Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 mars 1962, samedi 24 (no 12)
[" Tomb 94, No 12 1601 Vol.94, No.12 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Pag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Officii! Flag of the Province (14 Geo.VI, Ch.3) Gazette officielle de Québec (publiée par le gouvernement de la province) Quebec Official Gazette (published by the provincial government) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 24 mars 1962 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.Spécifier le nombre d'insertions.43 Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.( '> pendant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'in-térené doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sons préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., ¦out strictement payables d'avance.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, March 24, 1962 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the Two official languages.When same is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates herein below set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion : otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.'61, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Chester Krupa, executive, 120, Springfield Avenue, St-Hubert, John Herschorn, attorney, 1396, St.Catherine West, Montreal, and Patricia l.\">na Hyland Herschorn, secretary, wife separate as to property of the said John Herschorn, and duly authorized by him for the purpose of these presents, 595 Westluke Avenue, Côte-St-Luc, for the following purposes: * To carry on the business of builders and building contractors, under the name of \"Alcalum Products Limited\", with a total capital stock of $10.000.divided into 3,000 common shares of SI each and 70 preferred shares of SI00 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March ft 1962, VU.94, So.12 1603 I a' siège social f $100 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretar) this 27th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744-o 16204-61 \u2014 1110/118 Lake St.John Athletic Club Inc.Lake St.John Athletic Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de décembre 1961, constituant en corporation sans capital-actions: Henri-J.Lange-vin, papetier, Dolbeau, Charles Waldron, machiniste, Dolbeau, et Henri Roy, gérant de club, Dolbeau, pour les objets suivants: Établir, entretenir et diriger un club athlétique et stimuler entre les membres de la corporation et autres, un intérêt en faveur des jeux athlétiques, des divertissements et des sports, sous le nom de « Lake St.John Athletic Club Inc.».Le montant auquel est limité le revenu annuel de la propriété immobilière que la corporation peut posséder est $20,000.Le siège social de la corporation sera à Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de décembre 1961.1*.Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744 16015-61 \u2014 1109/77 l.aniel & Malouin Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1961, constituant en corporation: Gerald Laniel, agent d'assurances, 72, rue Mathias, Janine Sauvé l.aniel, ménagère, Notice is hereby given that under Part 111 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of December, 1001.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a cor poration without share capital: Henri-J.Lange-vin, paper maker, Dolbeau, Charles Waldron, machinist, Dolbeau, and Henri Roy, club manager, Dolbeau, for the following purposes: To establish, maintain and conduct an athletic club and to promote among the members of the Corporation and others an interest in athletic games, recreation and sports, under the nann of \"Lake St.John Athletic Club Inc.\".The amount to which the annual revenue of the immoveable property which the corporation may hold, is to be limited, is $20,000.The head office of the corporation will 1» at Dolbeau, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of December, 1961.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Provinci 60744-o 16015-61 \u2014 110077 Laniel & Malouin In* .Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters pat> at, bearing date the 1st day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gerald Laniel, insurance agent.72, Mathias Strict, Janine Sauvé Laniel, housewife, wife separate QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, '062, Vol.04, So.It 161a iiouse Réparée de biens dudit Gerald Laniel, 72, nie Mathias, et Jean-Maurice Laniel, comptable.60, rue Ellice, tous trois de Valleyfield, pour les 1,1)jets suivants: Kxercer le commerce de courtiers en assurances, «oui le nom de « Laniel & Malouin Inc.», avec un capital total de $25,000, divisé en 1,250 ictions ordinaires de $10 chacune et en 1.250 .ictions privilégiées de $10 chacune.I^e siège social de la compagnie sera à Salaher-ry-de-Valleyfield, district judiciaire de Beau bernois.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de décembre 1961.Ix Sous-secrétairt de la province, Raymond Douville.M744* 15442-61 \u2014 1106/120 Lansdowne Finance Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première' partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 18t jour de décembre 1961, constituant en ( orporation: David Gelbcr, administrateur, 802.Upper Lansdowne, Westmount, Sadie Gelbcr,* épouse séparée de biens dudit David Gelber.ménagère, 802, Upper Lansdowne, Westmount.I Nahum Gelber, avocat, 3605, Ridgewood, Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le commerce d'une compagnie de finance, sous le nom de « Lansdowne Finance \u2022 rporatinn », avec un capital total de $225,000.divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune \u2022 ; 20,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 771, est.nie St-Joseph, Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province.< e 18e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.'(1744 16101-61 \u2014 1109/79 J.M.Larrivée Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en ¦¦-< irporation : Nelson Ross, entrepreneur, Trois-Pistoles, Hervé Levasseur, bijoutier, 455, avenue Arnaud, Sept-Iles, et Hélène Milcendeau, secrétaire, célibataire majeure, 627, Brochu, Sept-Iles.pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « J.M.Larrivée Ltée », avec un \u2022apital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois-¦ 'is tôles, district judiciaire de Kamouraska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28é jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.-0744-o \u2022« 16212-61 \u2014 1109/117 J.-D.Leblond Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, ai date lu 28e jour de décembre 1961, constituant en as to property of the said Gerald Laniel, 72, Mathias Street, and Jean-Maurice Laniel, accountant, 60, Ellice Street, all three of Valley-field, for the following purposes: To carry on a business as insurance brokers under the name of \"Laniel & Malouin Inc.\", with a total capital stock of $25.000, divided into 1,250 common shares of $10 each and into 1,250 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Salabcrry-de-Valleyfield, judicial district of Beau-harnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of December.1961.Raymond.Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 15442-61 - 1106/120 I.ansdovwie Finance Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December.1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: David Gell>er, executive, 802, Upper Lansdowne.Westmount.Sadie Gelber, wife separate as to property of the said David Gelber, housewife, 802 Dppei Lansdowne, Westmount, and Nahum Gelbcr.lawyer, 3605 Ridgewood, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a finance company, under the name of \"I«ansdowne Finance Corporation\", with a total capital stock of $225,000, divided into 2,500 common shares of $10 each and 20.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 771, St.Joseph East, Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o 16101-61 \u20141109/79 J.M.Larrivée Ltée Notice is hereby given that und'.r Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Nelson Ross, contractor, Trois-Pistoles, Hervé Levasseur, jeweller, 455, Arnaud Avenue, Sept-Iles, and Hélène Milcendeau, secretary, spinster of the full age of majority, 627, Brochu, Sept-Iles, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"J.M.Larrivée Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this.28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 16212-61 \u2014 1109/117 J.-D.Leblond Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph- 1616 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 196$, Tome 94, No 12 corporation : Joseph -Donat Lehlond, commerçant, 543, boulevard Talbot, Chicoutimi, Pierre Bergeron, avocat, 110, rue Racine, est, Chicoutimi, et Huguette Gaudreault, secrétaire, célibataire majeure, 51, St-Dominique, est, Chicoutimi, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « J.-D.Lehlond Ltée », avec un capital total de $150,000, divisé en 60 actions ordinaires de $100 chacune, 2,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de $10 chacune et en 12,400 actions privilégiées l'lasse c B » d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 543, boul-levard Talbot, Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1961.L'e Soux-xecrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.60744-o 10000-1110/126 Donat Leblond, tradesman, 543, Talbot Boule, vard, Chicoutimi, Pierre Bergeron, advocate, 110, Racine Street, East, Chicoutimi, and Huguette Gaudreault, secretary, spinster of full age, 61, St-Dominique Street East, Chicoutimi, for the following purposes : To operate a business as an investment company under the name of \"J.-D.Leblond Ltée\", with a total capital stock of $150,000.divided into 60 common shares of $100 each, 2,000 pre.ferred class \"A\" shares of a par value of $|i) each and into 12,400 preferred class \"B\" shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at 543, Talbot Boulevard, Chicoutimi, judicial di trict of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secrtearv, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 16000\u20141110/120 la Légion Canadienne de Kénogami Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de décembre 1961, constituant en corporation sans capital-actions: Georges-Emile Côté, épieier, Jonquière, Jack Beresford, chimiste, Arvida, et Wilfrid Vallée, rentier, Kénogami, pour les objets suivants: Établir et diriger un club social, sous le nom de « La Légion Canadienne de Kénogami Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut posséder, est de 125,000.Le siège social de la corporation sera 101, rue Ste-Famille, Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de décembre 1961.l.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.607444 15972-61 \u2014 1108/103 La Légion Canadienne de Kénogami Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of December, 1001.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Georges-Emile Côté, grocer, Jonquière, Jack Beresford, chemist, Arvida, and Wilfrid Vallée, annuitant.Kenogami, for the following purposes: To establish and direct a social club, under the name of \"La Légion Canadienne de Kénognmi Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,0C0.The head office of the corporation will be at 101, Ste-Famille Street, Kénogami, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secrctarv.this 13th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 15972-61 \u2014 1108/1U3 Lemieux & Renaldy Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Laurent Renaldy, entrepreneur, Isle-Maligne, Jacques Harvey, comptable, St-Bruno, et André Boissonneault, avocat, 48, Sacré-Cœur, Aima, pour les objets suivants: Exercer le commerce de const moteurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Lemieux & Renaldy Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Aima, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de décembre 1901.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douville.60744m 16041-61 \u2014 1109/81 Lemieux & Renaldy Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1901.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Laim at Renaldy, contractor, Isle-Maligne, Jacques Harvey, accountant, St -Bruno, and André Boissonneault, advocate, 48, Sacré-Cœur, Alma, for the following purposes: To carry on a business as builders and general building contractors, under the name of \"Lemieux & Renaldy Ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Alma, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 16041-61 \u2014 1109 M Gérard Lesage Inc.Gérard Lesage Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1617 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de janvier 1062, constituant en corporal ion: Gérard Lesage, camionneur, 535, 119e rue, Shawinigan-Sud, Dame Ubalda Paillé Li sage, épouse commune en biens dudit Gérard lesage, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ménagère, 535, 119c rue, Shawinigan-Sud, et André Lesage, camionneur, 613, 2c rue, Sbawinigan, pour les objets suivants: Kxercer le commerce d'une compagnie de t ran-port, sous le nom de f Gérard Lesage Inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur an pair ou nominale et en 1,400 actions privilégiées de S25 chacune, et le montant avec lequel lu compagnie commencera ses opérations est de $tt,500.I.een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Yvon Labelle, grocer, 285, Roi-do-Nord Boulevard, Ste-Rose, Mrs.Claudette Barré, wife contractually separate as to property of the said Yvon Labelle, and duly authorized by him for these presents, housewife, 285, Roi-du-Nord Boulevard, Ste-Rose, and Mrs.Marie-Anne Clairmont, unremarried widow of Emile Labelle, housewife, 238, Ste-Rose Boulevard, Ste-Rose, for the following purposes: To carry on business dealing in all types of articles and merchandise in which a grocer-butcher generally deals, under the name of \"Marché Roseval Inc.\u2014 Roseval Market Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 146, Ste-Rose Boulevard, Ste-Rose, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 10188-62 \u2014 1109/101 Markal Inc.\\vis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de décembre 1961, constituant en «orporation: Jean-Louis I^amoureux, avocat, M 78, rue Wiseman, Montréal, J.-Êloi Gervais, avocat, 61, rue St-Charles, est, Longueuil, et ¦ ' '¦-incline Laliberté.secrétaire, fille majeure, 5609, rue Vian.Montréal, pour les objets sui vanté: Kabriquer, vendre et faire le commerce en gros de spécialités médicales et de préparations pharmaceutiques et médicales de toutes sortes, sous le nom de « Markal Inc.», avec un capital ! >tal de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires ''Une valeur nominale de $100*chacune et en 300 a-lions privilégiées d'une valeur nominale de % 100 chacune.lie siège social de la compagnie sera à Montréal.' strict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, 20e jour de décembre 1061.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10744-0 16133-61 \u20141110/18 \u201e Markal Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Louis Lamoureux, advocate, 8178, Wiseman Street, Montreal, .1.-ft loi Gervais, advocate, 61, St.Charles Street, east, Longueuil, and Jacqueline Laliberté, secretary, fille majeure, 5609, Viau Street, Montreal, for the following purposes: To make, sell and carry on a wholesale business dealing in medical specialties and pharmaceutical and medical preparations of all kinds, under the name of \"Markal Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $100 each and 300 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head Office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secçetary, this 20th day of December, 1961.Raymond Dol-ville, Assistant Secretary of the Province.60744 1613&6I \u2014 1110/18 1620 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, H mars 196S, Tome 94, No 1» Martin Steel Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des letties patentes,, en date du lie jour de décembre 1961, constituant en corporation: Mlle Marie-Claire Lemieux, avocate, 3445, Ridgewood, Montréal, Paul Lemieux, avocat, 409, Vauquelin, Bclocil, et Marcelle Roy, secrétaire, célibataire, 6923, 1ère Avenue, Montréal, pour les objets suivants: Industrie et commerce de métaux, sous le nom de « Martin Steel Ltd.», avec un capital total de $\u202210,000.divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 3,760 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de $10 chacune et en 1,400 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2915, rue Sherbrooke, est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce lie jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744-o 15981-61 \u2014 1108/106 Martin Steel Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1061, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Miss Maiie-Claire Lemieux, advocate, 3445, Ridgewood, Montreal, Paul Lemieux, advocate, 409, Vauquelin, Bclocil, and Marcelle Roy, secretary, spinster, 6923, 1st Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on the industry and business dealing in metal, under the name of \"Martin Steel Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each, 3,760 preferred class \"A\" shares of a par value of $10 each and 1,400 preferred class \"B\" shares of a par value of $1 each.The head office of the company will be ut 2915, Sherbrooke Street, east, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary/ of the Province.60744 15981-61 \u2014 ll'08/l()6 Maurice Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de janvier 19G2, constituant en corporation: Leo Rosentzveig, avocat, 4805, chemin Circle, Stanley Taviss, avocat, 6442 ouest, rue Sherbrooke, et William Levitt, avocat, 5020, avenue St.Kevin, tous trois de Montréal, pour les objets suivants : Exercer les affaires d'une compagnie de construction, d'immeubles et de placements, sous le nom de « Maurice Construction Inc.», avec un capital total de $30,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour de janvier 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744 10085-02\u20141110/110 Maurice Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of January, 19(12, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Leo Rosentzveig, advocate, 4805, Circle Road, Stanley Taviss, advocate, 6442, Sherbrooke Street West, and William Levitt, advocate, 5020, St.Kevin Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a construction, realty and investment company, under the name of \"Maurice Construction Inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o 10085-62 \u2014 1110/110 Léandre Michaud Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1961, constituant en corporation : Léandre Michaud, comptable, Mme Hélène Roy, épouse séparée de biens dudit Léandre Michaud, ménagère, et Albert Landry, commis, tous trois de Cabano, pour les objets suivants: Exercer le commerce de courtiers en assurance, sous le nom de « Léandre Michaud Inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 500 actions ordinaires de $50 chacune et en 500 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Cabano, district judiciaire de Kamouraska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de décembre 1961.IjC Sous-secrétaire de la province, » Raymond Douville.60744-o 15858-61 \u2014 1108/61 Léandre Michaud Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1061, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Léandre Michaud, accountant, Mrs.Hélène Roy, wife separate as to property of the said Léandre Michaud, housewife, and Albert Landry, clerk, all three of Cabano, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers, under the name of \"Léandre Michaud Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 500 common shares of $50 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Cabano, judicial district of Kamouraska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 15858-61 \u20141108/61 \\ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1621 M id town Hardware Distributors Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour d'octobre 1961, constituant en mu >i>ration: Moc Ackman, avocat, 3128, 3e rue, Chomedcy, Sydney Cutler, avocat, 6155, Northcrest, Montréal, Hershey B.Shron, m .\u2022 ¦ hand, 2150, Johnson, St-Lan rent, et Marilyn Berkovits, ménagère, é|>oiise séparée de biens de fluide Berkovits, 4750, Plamondon, Montréal, pour lesobjets suivants: Kxercer le commerce de marchands de quincaillerie, sous le nom de « Midtown Hardware Distributors Corp.», avec un capital total de $20.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.I/' siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, Ce 14e jour de mars 1902.Id Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744 15244-61 \u2014 1103/72 Midtown Hardware Distributors Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of October, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Moe Ackman, advocate, 3128, 3rd Street, Chomcdey, Sydney Cutler, advocate, 6155, Northcrest, Montreal, Hershey B.Shron, merchant, 2150, Johnson, St-Laurent, and Marilyn Berkovits, housewife, wife separate as to property of Emile Berkovits, 4750, Plamondon, Montreal, foi the following purposes' To carry on the business of hardware merchants, under the name of \"Midtown Hardware Distributors Corp.\", with a total capital stock of $20.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of March, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-0 15244-61 \u2014 1103/72 Kdgar Milot Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 12 décembre 1961, autorisant la fusion de t Edgar Milot Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 27 février 1947, et « Milot Construction Inc.», constituée en corporation en veitu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes du 22 décembre 1955, pour les objet\" suivants: Faire affaires dans le domaine de la construction, sous le nom de « Edgar Milot Ltée », avec un capital total de $90,000, divisé en 650 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le nom de la nouvelle compagnie est « Edgar Milot Ltée ».Le siège social de la compagnie sera dans les cité et district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 6 mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.007 Mo 2350-47 \u2014 1110/122 G.Miville-Dcchcne Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première part ie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du le jour de décembre 1961, constituant en corporation: Mme Marie-Rose Faucher Miville-Déchêne, veuve, ménagère, Yvon Miviile-Dé-ehêne, commis, Mlle Thérèse Miville-Déchêne, commis, Mlle Françoise Mhille-Déchéne, com-¦cis, et Lucien Miville-Déchêne, comptable, tous cinq de Saint-Georges-Est, pour les objets miivants: Faire le commerce de tissus de toutes sortes, sons le nom de « G.Miville-Déchéne Ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Edgar Milot Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act letters patent bearing date the 12th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, authorizing the amalgamation of \"Edgar Milot Inc.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act by letters patent dated the 27th day of February, 1947, and of \"Milot Construction Inc.\", incorporated under said Part I of the Quebec Companies Act, by letters patent dated the 22nd day of December, 1955, for the following purposes: To carry on business in the world of building, under the name of \"Edgar Milot Ltée\", with a.total capital stock of $90,000, divided into 650 common shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each.The name of the new company is \"Edgar Milot Ltée\".The head office of the company will be in the city and judicial district of Montreal.\u2022 Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of March, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 2350-47\u20141110/122 G.Miville-Déchêne Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Mrs.Marie-Rose Faucher, Miville-Déchéne, widow, housewife, Yvon Miville-Déchéne, clerk, Miss Thérèse Miville-Déchéne, clerk, Miss Françoise Miville-Déchêne, clerk, ami Lucien Miville-Déchêne, accountant, all five of Saint-Georges-East, for the following purposes: To carry on a business dealing in all kinds of cloths, under the name of \"G.Miville-Déchêne Ltée\", with a total capital stock of $40,000 divided into 400 common shares of $100 each 1622 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mon 1962, Tome 94, No 12 Le siège social de la compagnie sera 281, 1ère avenue, Saint-Georges-Est, district judiciaire de Bounce.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744-o 15609-61 \u2014 1105/131 Modem Frame Shop Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Bernard Dcsjarlais, avocat, 1600, Stephens, Verdun, Albert Ouellette, avocat, 786, Vachon, LaSalle, et Rcma Cousineau, avocat, 5652, Drake, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et de nouveautés de toutes sortes, sous le nom de f Modem Frame Shop Ltd.», avec un capital total de $100,000, divisé en 650 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8586, 10e avenue, Saint-Michel, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.60744-o 16077-61 \u2014 1108/136 Monat & Bleau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, .en date du 13e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Jacques-A.Belislè, avocat, 20, rue St-Jacques, est, chambre 21, Montréal, Marie-Claire Lefebvre, avocate, célibataire, 20, rue St-Jacques, est, chambre 21, Montréal, et Gisèle Belisle Roten, épouse contractuellement séparée de biens de Roger Roten, secrétaire, 6955, rue Fielding, #315, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, sous le nom de « Monat & Bleau Limitée », avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 13e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.60744-o ' 16020-61 \u2014 1109/34 Moulding Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la provincede Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant eh corporation: Seymour Machlovitch, avocat, 3445, Côte-des-Neiges, Montréal, Jack Shayne, avocat, 125, avenue Dorval, Dorval, et Shirlee Simon, secrétaire, fille majeure, 1460, Van Home, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à fabriquer, laminer et ajuster des moulures et produits The head office of the company will be at 281, 1st Avenue, Saint-Georges-East, judicial district of Beauce.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province 60744 15609-61 \u20141105 Ml Modern Frame Shop Ltd.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters pat\u2022 it, bearing date the 20th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province cf Queb?c, incorporating: Bernard Dcsjarlais, advocate, 16C0, Stephens, Verdun, Albert Ouellette, advocate, 786, Vachon, LaSalle, and Roma Cousinesu, advocate, 5652, Drake, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Modern Frame Shop Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 650 common shares of a par value of $100 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 8586, 10th Avenue, Saint-Michel, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of December, 1901.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744 16077-61 \u2014 1108/136 Monat & Bleau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province cf Quebec, incorporating: Jacques-A.Belisle, advocate, 20, St.James Street east, room 21, Montreal, Marie-Claire Lefebvre, advocate, spinster* 20, St.James Street cast, room 21, Montreal, and Gisèle Belisle Roten, wife contractually separate as to- property of Roger Roten, secretary, 6955, Fielding Street, # 315, Montreal, for the following purposes: To carry on business as printers, under die name of \"Monat & Bleau Limitée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 sii res of $10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 16020-61 \u2014 110' 34 Moulding Products Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters pat int.bearing date the 28th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Seymour Machlovitch, advocate, 3445, Côte-des-Neiges, Montreal, Jack Shayne, advocate, 125, Dorval Avenue, Dorval, and Shirlee Simon, secretary, fille majeure, 1460, Van Home.Montreal, for the following purposes: To cany on the business of manufacturing, milling and machining mouldings and allied QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1623 connexes, sous le nom de « Moulding Products Ltd.», avec un capital total de £10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de SI chacune et 30.000 «étions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.C744 16241-61 \u2014 1110/119 Nouveautés Mondiales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partis de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Bernard Laferrière, gérant, 7472, rue Fabre, Montréal, Lucien Paquet, vitrier, 8942.Berri, Montréal, et Yvon Fariner, plom-hii-r, 4592, Christophe-Colomb, Montréal, pour I.; objets suivants: Faire affaires comme publicitaires, sous le h.un de « Nouveautés Mondiales Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions de §100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de décembre 1961.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.60744m 14631-61 \u2014 1108/62 products, under the name of '\"Moulding Products Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, A*si*tant Secretary of the Province.60744-o 16241-61\u2014 1110/119 Nouveautés Mondiales Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, lctteis patent, bearing date the 2Xth day of December, 1901, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Qucl>cc, incorporating: Bernard Laferrière, manager, 7472, Fabre Street, Montreal, Lucien Paquet, glass-maker, 8942, Berri, Montreal, and Yvon Farmer, plumber, 4592.Christopher-Columbus, Montreal, for the following purposes: To carry on business as publicists, under the name of \"Nouveautés Mondiales Inc.\".with a total capital stock of $20.000, divided into 200 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 14631-61 \u2014 1108/62 L'O.T.J.de St-Cômc, Beauce Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation sans capital-actions: Aurèle Paquet, négociant, Lucien Dumas, entrepreneur, André Doyou, boulanger, Philippe Giguère, contremaître, Renaud Létourneau, journalier, Marcel \u2022iraudo, mécanicien, Paul-Henri Bélanger, con-¦0744-« 15836-61 \u2014 1107/115 Radio Srpt-Ilienne Inc.Precision Hydraulic Manufacturing Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Miss Colombe Pilon, accountant, 4315 de Castille, Montreal-North, Claude Pilon, mechanic, 25 Diane Street, Jacques-Cartier, Jean-G.Pilon, mechanic, 213 Diane Street, Jacques-Cartier, Henri Pilon, administrator, 51 Diane Street, Jacques-Cartier, and Marcel Pilon, administrator, 5C03 Beaugrand Place, Montreal, for the following purposes: To carry on a business of any hydraulic, diesel, motor, machinery equipment and all the accessories and parts, under the name of \"Precision Hydraulic Manufacturing Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 15836-61 \u2014 1107/115 Radio Sept-Ilienne Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a 1636 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 24 mm 1962, Tome 94, No 12 été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1061, constituant en corporation: Monique Baillargeon, secrétaire, épouse contractuellement séparée de biens de Bruno Cyr, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, Annette Pelletier, secretaire, épouse judiciairement séparée de corps et de biens de Laurent Pelletier, et Bruno Cyr, avocat, tous trois de 507, Place d'Aï mes, Montréal, pour les objets suivants : Acquérir, louer, posséder, établir, outiller, entretenir et exploiter des postes émetteurs et récepteurs de radio-diffusion et de TSF, sous le nom de « Radio Sept-llienne Inc.», avec un capital divisé en 5.0C0 actions sans valeur au pair ou nominale et en 5,000 actions privilégiées de $20 chacune, et le montant avec lequel la compagnie commencera ses opérations est de $35,000.Le siège social de la compagnie sera à Sept-Iles, district judiciaire de Saguenay.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de novembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60744-o 15663-61 \u2014 1106/108 bearing date the 23rd day of November, 190!, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Monique Baillargeon, secretary, wife contractually separate as to property of Bruno Cyr, and duly authorized by him for these presents, Annette Pelletier, secretary, wife judicially separate as to bed and board of Laurent Pelletier, and Bruno Cyr, advocate, all three of 507 PL- e d'Armes, Montreal, for the following purpos- - : To acquire, rent, own, establish, equip, maintain and operate broadcasting and receiving stations and wireless, under the name of \"Radio Sept-llienne Inc.\", with a-capital stock divided into 5,000 shares without nominal or par value and into 5,000 preferred shares of $20 each, and the amount with which the company shall start its operations is $35,000.The head office of the company will be at Sept-Iles, judicial district of Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretary, tlis 23id day of November, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744 15663-61 \u2014 1106/1118 Restaurant Chinois Dragona Inc.Chinese Restaurant Dragona Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de novembre 1961, constituant en corporation: Lionel Founder, employé civil, 748, Côte d'Abraham, Québec, Roger Bouchard, vendeur d'automobiles, 122, boulevard Central, Petite-Rivière-Nord, et Guy Lepage, employé à 1'Anglo Pulp, 199, 24e rue, Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de c Restaurant Chinois Dragona Inc.\u2014 Chinese Restaurant Dragona Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au Oui eau du secrétaire de la province, ce 29e jour de novembre 1961.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744-o 15787-61 \u2014 1108/112 Restaurant Chinois Dragona Inc.Chinese Restaurant Dragona Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of November, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lionel Founder, civil employee, 748, Abraham Hill, Quebec, Roger Bouchard, automobile salesman, 122, Central, Boilevard, Petite-Rivière-du-Nod, and Guy Lepage, employee at the Anglo Pulp, 199, 24th Street, Quebec, for the following purposes: To carry on a business as restaurateurs under the name of \"Restaurant Chinois Dragona Inc.\u2014 Chinese Restaurant Dragona Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of November, 1961.«*, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.60744 15787-61 \u2014 110S'12 Les Restaurants Lemober Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Henri Bergeron, commerçant, 142, rue Panet, Constance Claveau Bergeron, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Henri Bergeron, et dûment autorisée par lui aux fins des présertes, 142, rue Panet, et Jean-Guy Morel, commerçant, 148, rue St-Jules, tous trois de Jonquière, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Les Restaurants Lemober Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.% Le siège social de la compagnie sera à Jonquière, district judiciaire de Chicoutimi.Les Restaurants Lemober Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent bearing date the 29th day of December, 1!'til, have been issued by the Lieutenant-Governi of the Province of Quebec, incorporation: Henri Bergeron, tradesman, 142, Panet, Street, Constance Claveau Bergeron, housewife, wife con-tractually separate as to property of the aid Henri Bergeron, and duly authorized by him for these presents, 142, Panet Street, and Jean-Guy Morel, tradesman, 148, St-Jules Street, all three of Jonquière, for the following purposes: - To carry on a business of restaurateurs under the name of \"Les Restaurants Lemober Inc.\", -with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $100 each.The head office of the company will b* at Jonquière, judicial district of Chicoutimi. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.9/,, No.12 1627 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de décembre 1901.Ci Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.¦ .0714-0 14179-61 - 1108/130 La Kiviera Chomedey Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première I trtie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la |ir.)vince de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1961, constituant en \u2022 iponitidn: René Amyot, avocat, 1407, avenue Oak, Silûry, Mlle Pierrette Trottier, secrétaire, 610, rue Lavigueur, Quebec, J.-Alfred Pelletier, comptable, 35, du Roi, est, Québec, Mlle Alber-line Chouinard, comptable, 160, 10e rue, Québec, et Mlle Denise Vachon, secrétaire, 1516, nie Vitré, Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôteliers, sous le nom ffiee of the Provincial Secretary, this 21st day of December, 1061.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 15630-61 \u2014 1108/38 Sodima Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 1st day of December, 1961, have been i-sued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Miss IiOrraine Sepuin, secretary, 21 Cicot Avenue, Boucherville, Maurice Riel, advocate, 780 Mark-ham Road, Mount-Royal, Clermont Vermctte, advocate, 235 de Salaberry Boulevard, La Prairie, Gérald L< Dai¦>, advocate, 140 de Normandie Street, Préville, Godfroy Marin, advocate, 78 Chester Avenue, Pointe-Claire, Jules Léger, notary, 3320 Sherbrooke, East, Montreal, and Laurent Décarie, notary, 5824 Côte-des-Neiges, Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in alcoholic beverages ard otherwise, under the name of \"Sodima Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 7705, 18th Avenue, Saint-Michel, judicial dis-trist of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st ec, dated the 2nd day of February, 1962, to \"Sylvio Gendron Inc.\", extending its powers.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 10015-59\u2014 1112/127 Greenoch Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Greenoch Investments Ltd.\", reducing its capital from $1,672,756 to $60,000, the capital stock annulled being divided into 40,000 common shares of $1 each and 1,572,756 preferred shares of $1 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistatit Secretary of the Province.60744-o 10341-59\u20141112/26 Greenoch Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Qui'bec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 décembre 1961, à lu ¦\u2022ompagnie «Greenoch Investments Ltd.», 1° réduisant son capital de $2,163,429 à $172,756, le capital-actions annulé étant divisé en 1,990,673 actions privilégiées de $1 chacune; 2° augmentant son capital de $172,756 à $1,672,756, la capital-actions additionnel étant divisé en 1,500,000 actions privilégiées de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 14 décembre 1961.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.«0744 10341-59\u2014 1107/22 Henderson Furniture Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en elate du 17 janvier 1962, à la compagnie « Henderson Furniture Limited », étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 17 janvier 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.\u202210744*0 3598-46 \u2014 1110/134 Inter-City Finance Inc.Finance Inter-Cité Inc.Avis est donné,qu'en vertu de la première partis de la Loi des compagnies de Québec, il a «¦te accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 1er février 1962, à la compagnie « Veteran Finance Inc.», constituée par lettres patentes en date du 12 mars 1957, changeant son nom en celui de « Inter-City Finance «ne \u2014 Finance Inter-Cité Inc.».Greenoch Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 14th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Greenoch Investments Ltd.\", 1.reducing its capital frcm $2,1(13,429 to $172,756, the capital stock annulled being divided into 1,990,673 preferred shares of $1 each; 2.increasing its capital from $172,756 to $1,672,756, the additional capital stock being divided into 1,500,000 preferred shares of $1 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.6074 4-o 10341-59 \u2014 1107/22 Henderson Furniture Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 17th day of January, 1962.to \"Henderson Furniture Limited\", extending its powers.Given at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 3598-46 \u2014 1110/134 Inter-City Finance Inc.Finance Inter-Cité Inc.Notice is hereby given that under Part J of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 1st day of February, 1962, to \"Veteran Finance Inc.\", incorporated by letters patent on March 12, 1957, changing its name into that of \"Inter-City Finance Inc.\u2014 Finance Inter-Cité Inc.\". 1038 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 nuira 1962, Tome 94, No 12 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er février 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744-o 10377-57\u2014 1113/52 Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 10377-57 \u2014 1118/52 Laurentian Car Centre Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 7 décembre 1961, à la compagnie « Laurentian Car Centre Co.Ltd.», modifiant certaines dispositions de ses lettres patentes.Donné au bureau du secrétaire de ht province, ce 7 décembre 1961.Lf Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744-o 13250-60 \u20141107/100 Laurentide Automobiles Inc.(1951) Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 22 décembre 1961, à la compagnie « Laurentide Au ton» biles Inc.(1951) ».1° subdivisant ses 249 actions ordinaires de $100 chacune en 24,900 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune; 2 étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22 décembre 1961.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744-o 1450-51 \u20141106/137 Magasin Pembrooke Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des cempegnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 janvier 1962, à la compagnie c Desnoyers & Beauchemin (1959) Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er jour d'octobre 1959, changeant son nom en celui de « Magasin Pembrooke Ltée ».Donné au bureau du secrétaire de la province, le 19 janvier 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744 15556-59 \u2014 1111/44 Midtown Hardware Distributors Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 28 novembre 1961 à la compagnie « Midtown Hardware Distributors Corp.», augmentant son capital de $20,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 7,000 actions privilégiées de $10 chacune.Donné au bureau du Secrétaire de la province, le 28 novembre 1961.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744 15244-61 \u2014 1112/104 Laurentian Car Centre Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 7th day of December, 1962, to \"Laurentian Car Centie Co.Ltd.\", amending certain provisions of its letters patent.Given at the office of the Provincial Secretan.this 7th day of December 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 13250-60 \u2014 1107/100 Laurentide Automobiles Inc.(1951) Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Ctmpanics Act, supplementary Jettera patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, dated the 22nd day of December, 1961, to \"Laurentide Automobiles Inc.(1951)\", 1.subdividing its 219 common shares of $ 1C0 each into 24,900 common shares of a par value of $1 each; 2.extending its powers.Given at the office of the Provincial Secretsiy, this 22nd day of December, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 1450-51 \u2014 1106/137 Magasin Pembrooke Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Desnoyers & Beauchemin (1959) Inc.\", incorporated by letters patent dated the 1st day of October, 1959, changing its name to that of \"Magasin Pembn o-ke Ltée\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o 15556-59\u20141111 14 Midtown Hardware Distributors Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 28th day of November, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Midtown Hardware Distributors Corp.\", increasing its capital from $20,000 to $100,000, the additional capital stock being divided into 1,000 common shares of $10 each and 7,000 preferred shares of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of November, 1961.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o .15244-61 \u20141112/104 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24.1962, Vol.94, So.12 1639 Monarch Securities Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partis de la Ii des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 décembre 1961, à la compagnie « Citroen Prestige Rentals Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 23e jour de juin 1961, changeant son nom en celui de « Prestige Rentals Inc.».Donné au bureau du secrétaire de la province, le 21 décembre 1061.Le Sous-secrêtuire de la province, Raymond Douville.«0744 13254-61 - 1109/112 Province Island Fishing & Came Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, d«*s lettres patentes supplémentaires, en date du 5 janvier 1962 à la compagnie « Province Island Fishing & Game Club Inc.», étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 5 janvier 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744 14118-60\u2014 1112/17 Quebec Industrial Towels Ltd.Lei Serviettes Industrielles de Quebec Ltée Avis est tlonné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 29 janvier 1962, à la compagnie « Advantage Towel Incorporated », constituée en corporation par lettres patentes en date du 6e jour de mars 1961, changeant son nom en celui de « Quebec Industrial Towels Ltd.\u2014 Les Serviettes Industrielles de Québec Ltée ».Donné au bureau «lu secrétaire de la province, le 29 janvier 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744 11172-61 \u2014 1112/112 Radionettc (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 25 janvier 1962, à la compagnie « Scandinavian Distributors Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 1er jour d'août 1958, changeant son nom en celui de « Radionette (Canada) Ltd.».Donné au bureau du secrétaire de la province, le 25 janvier 1962.l^e Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.60744 12738-58 \u2014 1111/108 L.A.Kohi tu il le Automobile Inc.Avis est tlonné 8.changing its name to that of \"Radionette 'Canada) Ltd.\"., Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o 12738-58\u2014 111 1/108 L.A.Robitaille Automobile Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March §4% 1962, Vol.94, No, 12 m) province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 5 janvier 1962, à la compagnie « L.A.Robitaille Automobile Inc.», étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5 janvier 1962.£# Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.lit)744-o 12554-51 \u2014 1110/136 Governor of the Province fo Quebec, dated the 5th day of January, 1962, to \"L.A Robitaille Automobile Inc.\", extending its powers.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 5th «lay of January, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 12554-51 \u2014 1110/136 Robert Rouleau Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenunt-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 1er février 1062, à la compagnie « Jabo Ltd.», eonetitutee en corporation par lettres patentes datées «lu 9e jour de mai 1961, 1° changeant son nom en celui de « Robert Bouleau Investments Ltd.»; 2° étendant ses pouvoirs.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, le 1er février 1902.Le Sous-secrêtaire de la protnrtce, Raymond Douville.m'714 12242-61 \u2014 1113/16 Silver Stable» Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu 25 janvier 1962, à la compagnie « Dunby Stables Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date «lu lie jour de mai 1961,,changeant son nom en celui de f Quebec, to \"Jabo Ltd.\".incorporated by letters patent dated the 9th day of May, 1961.1.changing its name to that of \"Robert Rouleau Investments Ltd.\"; 2.extending its powers.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.00744-o 12242-61 \u2014 1113/16 Silver Stables Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «lato the 25th day of January.1962.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Dunby Stables Inc.\", incorporated by litters patent dated the 3rd «lay of May, 1961, (hanging its name to that of \"Silver Stables Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744 12210-61 \u2014 1113/14 Traders Manufacturing Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 26 janvier 1962, à la compagnie « Traders Manufacturing Co.Ltd.», augmentant son capital de $99,000 à $102,000, le capital-actions additionnel étant divisé en ¦{,000 actions privilégiées de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 26 janvier 1962.IjC Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.00714 5537-41 \u2014 1112/18 Traders Manufacturing Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of January, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Traders Manufacturing Co.Ltd.\", increasing its capital from $99,000 to $102.000, the additional capital stock being divided into 3,000 preferred shares of $1 each.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 26th day of January, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60744-o 5537-41 \u2014 1112/18 Trans-Canada Ropeways Ltd.Avis est tlonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 19 janvier 1962, à la compagnie « Trans-Canada Ropeways Ltd.», 10 réduisant son capital de $40,000 à $7,000, le capital-actions annulé étant divisé en 330 actions ordinaires de $100 chacune; 2° augmentant son capital de $7,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 330 actions ordinaires «le $100 chacune et en 600 actions privilégiées de $100 chacune.I ru n s -Canada Ropeways Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, «lated the 19th day of January, 1962, to \"Trans-Canada Ropeways Ltd.\", 1.re«lucing its capital stock from $40,000 to $7,000, the cancelled share capital being divi«le«l into 330 common shares of $100 each; 2.increasing its capital stock from $7,000 to $100,000, the ad«litional share capital l>eing divklcd into 330 common shares of $100 each and 600 preferred shares of $100 each. 1642 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Toiiu 94, No 12 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19 janvier 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.60744-o 13818-61 \u2014 1112/69 1215 Phillips Square Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de In Loi des compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 décembre 1961, à la compagnie « 1215 Phillips Square Limited », 1° convertissant 198 actions ordinaires de $5 chacune en 198 actions privilégiées catégorie « C » de $5 chacune; 2° consolidant 100,000 actions privilégiées catégorie « B » de SI chacune en 1,000 actions privilégiées catégorie « B » de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, le 19 décembre 1961.Le Soue-eecrétaire de la province, Raymond Douville.60744 10384-54 \u2014 1110/104 (iiven at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of January, 1962.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744 13818-61 \u2014 1112/6» 1215 Phillips Square Limited Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of December, 1961, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"1215 Phillips Square Limited\", 1.converting 198 common shares of $5 each into 108 class \"' preferred shares of $5 each; 2.consolidating 100,000 class \"B\" preferred shares of $1 each into 1,000 class \"B\" preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of December, 1961.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744-o 10384-54 \u2014 1110/104 Ventes pour taxes Sales for Taxes Municipalité du comté de Dorchester Avis public est par les présentes donné par Raymond Laçasse, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de Dorchester, que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique pour taxes municipales et/ou scolaires dues et les frais encourus, JEUDI, le DIXIÈME jour de MAI 1962, en la salle du Conseil du comté, à Sainte-Hénédine, à DIX heures de l'avant-midi, à moins que les taxes et les frais encourus n'aient été payé avant la date di-dessus mentionnée.Municipality of the county of Dorchester Public notice is hereby given by Raymond Laçasse, secretary-treasurer for the municipal corporation of Dorchester county, that the under described properties will be sold by publie auction for municipal and/or school taxes due and charges incurred, THURSDAY, the TENTH day of MAY, 1962, in the hall of the county's council, at Sainte-Hénédine, at TEN o'clock in the morning, unless these taxes and charges be paid before the day above mentioned.Municipalité de Louis Joliet \u2014 Municipality of Louis Joliet Propriétaire Owner Lot Rang Range Canton Township Superficie Area Taxes munie.Munie, taxes Taxes «col.School taxes Frais Charges Total Clément Lavallée.S.O.de la Rivière \u2014 8.W.of the River.Un terrain étant le lot No 368 du cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Claire, en la municipalité de Louis Joliet et situé dans le rang sud-ouest de la rivière.70.40 arp.$193.90 $21.82 $487 «7 $271.95 A pice of land being lot No.368 on the official ea-daster for the parish of Sainte-Claire in the municipality of Louis Joliet and situated in the south western range of the river.Municipalité de Saint-Benjamin \u2014 Municipality of Saint-Benjamin Antoine Floury.786.XIII.Cram bourne.$126.00 $111.00 $17.24 $254 24 Municipalité de Sainte-Claire \u2014 Municipality of Sainte-Claire Arthur Ste-Marie.I 274.|.I.| I00.arp.| $ 92.92 | $237.75 | $ 6.47 | 1337 i Le lot No 274 du cadastre officiel de la paroisse de Lot No.274 on the official cadaster for the parish of Sainte-Claire, mesurant 100 arpents en superficie.Sainte-Claire, measuring 100 arpents in area.Municipalité de Sainte-Marguerite\u2014 Municipality of Sainte-Marguerite \t.173.\t\t\t\t\t\t \t174.\t\t\t\t\t\t \t1 151.\t\t\t269 arp.\t$ 50.42\t$380.92\t $431.34 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1062, Vol.94, So.12 1043 I'n terrain, avec bâtisses y érigée», étant les lots Ko* 173-174, du cadastre officiel pour la paroisse de Stinte-Marguerite, bornés au nord par le chemin Saint-Jtii' Mr.Laurent Monette.Municipal taxes for 1962 and arrears: $31.50; interest and notice: $2.11; school taxes for 1962 and arrears: $51.80; interest: $2.57.Total: $87.98.Mr.Laurent Morette, address unknown.\u2014 Lot No.Pt.847, 8th range, in the township of Chatham, 50 feet by 1C0 fc« t, bounded north by Half Moon Lake, w \\st by the same part of lot No.847 belonging to Mr.'ulien Charlcbois, south and east by the same part of lot No.847 belonging to Mr.Peter Watson.Municipal taxes for 1962 and arrears: 831.50; interest and notice: $2.11; school taxes for 1962 and arrears: $51.80; interest: $2.57.Total: $87.98.Mr.Henri Filion, R.R.5, Lachute, Quebec.\u2014 Lot No.Pt.580, 5th range, in the township ol Chatham, 80 feet by 100 feet, with buildings thereon erected, bounded south by the Route No.8, east by a public road, north by the same part of lot No.580 belonging to Mr.René Gagné, west by the same part of lot No.580 belonging to Mr.Adélard Gagné.Municipal taxes for 1962 and arrears: $76.50; interest and notice: $4.40; act of agreement: $93.51; school tax arrears: $93.50; interest and notice: $12.86; business tax for 1962 and arrears: $30.00.Total: $310.77.Mr.Heinz Fisher, address unknown.\u2014 Lot No.Pt.876, 9th range, in the township of Chatham, 70' by 56' by 150', bounded north by a gully, east by a private road, south by the same lot-No.876 belonging to Mr.Arthur Campbell, west by a dam' lake, with buildings thereon erected.Municipal taxes for 1962 and arrears: $13.50; interest and notice: $1.20.Total: $14.70.Mr.Hervé Gagné, Pine Hill, Quebec.\u2014 Part lot No.920, 9th range, in the township of Chatham, 83 acres, bounded west hy the same part of lot No.920 belonging to Mr.J.D.Patterson and part to Mr.Joseph Christin, cast by the same part of lot No.920 belonging to Mr.Douglas Arnold, north by a public road, south by the range line between 8th and 9th range.Municipal taxes, for 1962 and arrears: $30.90; interest and notice: $3.23; school taxes for 1962 and arrears! $48.25; interest: $2.42.Total: $84.80.Mr.Hervé Gagné, Pine Hill, Quebec \u2014 Part lot No.1011, .11th range, in the township of Chatham, 65 feet by 80 feet by 70 feet, with buildings thereon erected, bounded west by a public road, east and south by the remainder of lot No.1011, north by the same part of lot No.1011 belonging to Mr.Napoléon Carrière.Municipal taxes for 1962 and arrears: $122.92; interest and notice: $13.40; school taxes for 1962 and arrears: $125.44; interest: $3.74.Total: $265.50.Mr.Felix Mish, address unknown.\u2014 Lot No.Pt.966, 10th range, in the township of Chatham, east side 100 feet west side 100 feet, south side 140 feet, north side 120 feet, with buildings 1640 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, fi mars 1062, Tome 04, So lit dessus érigées, borué à l'est par la rivière Ouest, au nord par la même partie du lot No 966 appartenant à Mme Eva Paradis, à l'ouest par un droit de passage en commun, au sud par un chemin privé.Taxes municipales pour 1962 et arrérages: $27.00; intérêts et avis: $1.88.Total: $28.88.M.Eddie Williams, adresse inconnue.\u2014 Lot No 718, 6e rang, dans le canton de Chatham, 148 pieds sur 107 pieds, avec les bâtisses dessus érigées, borné à l'est pur un chemin de traverse, au sud et à l'ouest par la même partie du lot No 718 appartenant à M.Walter Wert, au nord par la même partie du lot No 718 appartenant à M.Lawrence Plummer.Taxes municipales pour 1962 et arrérages: $41.30; intérêts: $3.18.Total: $44.48.M.Jean-Guy Lafleur, R.R.1, Saint-Philippe d'Argenteuil, P.Q.\u2014 Lot No 722, 6e rang, dans le canton de Chatham.Taxes municipales pour 1962 et arrérages: $41.30; intérêts et avis: $3.63; arrérages de taxes scolaires: $19.25; intérêts et avis: $2.21.Total: $66.39.M.Paul-Êmile Lafleur.R.R.1, Saint-Philippe d'Argenteuil, Québec.\u2014 Lot No 550, 3e rang, dans le canton tie Chatham.Taxes municipales pour 1962 et arrérages: $18.00; intérêts et avis: $1.12.Total: $19.12.Municipalité de la paroisse de Saint-Jérusalem Mme Aline Normand Des jardins, 9150, rue Verville, Montréal, Québec.\u2014 Partie lot 1405, subdivision 199, dans la paroisse de Saint-Jérusalem, 1 lot à bâtir, sans bâtisses, au coin de la rue Noble et «lu boulevard Tessier.Taxes municipales: $183.03; taxes scolaires: $6.76; frais: $13.05.Total: $202.84.M.Henri Lemay, 446, Chemin Normandie, app.114, Pont Vian.\u2014Lot P.1410, dans la paroisse de Saint-Jérusalem.100 pieds sur 200 pieds, un lot â bâtir, face au nord sur le chemin du Moulin, avec les bâtisses dessus érigées, borné à l'ouest par le lot P.1410, René Lavigne, au sud par le résidu du lot P.1410, Fernand Coderre, et borné à l'est par P.1410, Albert Robbins.Taxes municipales: $87.26; taxes scolaires: $132.17.Total: $219.43.Suce.J.K.MacKimmie, a/s D.R.Bradfoid, exécuteur.\u2014 Lot P.1896, dans la paroisse de Saint-Jérusalem, 28 acres, sur le chemin Dunany, sans bâtisses dessus érigées, le tiers non-divisé du lot 1896, borné au noid par partie 1896 Mme W.H.Goodwin, au sud par partie 1896 « Daleco Investment Corp.», à l'est par le lot 1899 et à l'ouest par le lot 1860.Taxes municipales: $6.90; taxes scolaires: $12.21; frais: $1.05.Totak $20.16.AhVrt Legault, R.R.2, Lachute, Québec \u2014 Lot P.1412, dans la paroisse de Saint-Jérusalem, grand lot à bâtir avec bâtisses dessus érigées, face à l'ouest sur la route 31.borné au nord par les limites de la ville de Lachute, à l'est par le résidu du lot P.1412 et au sud par le lot P.1412 propriété de L.H.Demerse.Taxes municipales: $192.27; taxes scolaires: $94.64; frais: $10.50.Total: $297.41.J.A.Tessier, 228, avenue Barron, Lachute, Que.\u2014Lot P.696, subdivision 246, dans la paroisse de Saint-Jérusalem, approximativement 50 pieds sur 137.6 pieds, sans bâtisses dessus érigées, sur l'avenue,Barron.Taxes municipales: $127.30.Total: $127.30.Municipalité de Wentworth-Nord François Thibault, adresse inconnue.\u2014 Lot de terre portant le numéro Yi ouest 19 rang 3, thereon erected, bounded east by the V River, north by the same part of lot No.belonging to Mrs.Eva Paradis, west by a e mon right of way, south by a private i.Municipal taxes for 1962 and arrears: $27 interest and notice: $1.88.Total: $28.88.Mr.Eddie Williams, address unknowi Lot No.Pt.718, 6th range, in the townslnj Chatham, 148 feet by 107 feet, with build thereon erected, bounded east by a cross r< south and west by the same part of lot No.belonging to Mr.Walter Wert, north by the s part of lot No.718 belonging to Mr.Lawn Plummer.Municipal taxes for 1962 and arre $41.30; interest: $3.18.Total: $44.48.Mr.Jean-Guy Lafleur, R.R.1, Saint-Phih d'Argenteuil, P.Q.\u2014 Lot No.722, 6th range the township of Chatham.Municipal taxes 1962 and arrears: $41.30; interest and not $3.63; school tax arrears: $19.25; interest i notice: $2.21.Total: $66.39.Mr.Paul-Emile Lafleur, R.R.1, Saint J lippe, d'Argenteuil, Quebec.\u2014 Lot No.550, range, in the township of Chatham.Mum.taxes for 1962 and arrears: $18.00: interest notice: $1.12.Total: $19.12.Municipality of the parish of Saint-Jem-.Mrs.Aline Normand Desjardins, 91 SO.Verville, Montreal, Quebec \u2014 Pt.lot 1405, .division 199, in the parish of Saint Jem-.1 building lot, without buildings, on the cor of Noble Street and Tessier Boulevard.Mun pal taxes: $183.03; school taxes: $6.76; eu $13.05.Total: $202.84.Mr.Henri Lemay, 446, Chemin Norma ¦ ¦ apt.114, Pont Viau.\u2014 Lot Pt.1410, in the pai of Saint-Jérusalem, 100 feet by 200 feet, i building lot facing north on the Mill Road, « buildings thereon, bounded on the west bj Pt.1410, René Lavigne, south by the residue lot Pt.1410, Fernand Coderre, and bounded e by Pt.1410, Albert Robbins.Municipal tai $87.26; school taxes: $132.17.Total: $219,'\" Est.J.K.MacKimmie, c/o D.R.Bradh executor.\u2014 Lot Pt.1896, in the parish of Sai Jérusalem, 28 acres, on the Dunany Road, wi out buildings thereon, the undivided third lot 1896 bounded on the north by Pt.18 Mrs.W.H.Goodwin, south by Pt.1896, Dal Investment Corp., east by lot 1899 and west lot 1860.Municipal taxes: $6.90; school tax $12.21; costs: $1.05.Total: $20.16.Albert Legault, R.R.2, Lachute, Quebec Lot Pt.1412, in the parish of Saint-.Ierus.dr large building lot with buildings thereon faci west on Route 31, bounded north by the limits Lachute Town, east by the residue of Lot 1412 and south by lot Pt.1412 property of L Demerse.Municipal taxes: $192.27; school tax $94.64; costs: $10,50.Total: $297.41.J.A.Tessier, 228, Barron Avenue, Lachu Que.\u2014Lot Pt.696, subdivision 246, in 1 parish of Saint-Jérusalem, approximately 50 fi by 137.6 feet, without buildings thereon.Barron Avenue.Municipal taxes: $127.30.Tot $127.30.Municipality of Wentworth-North Francois Thibault, address unknown \u2014 T lot of land bearing the number }$ west 19, ran QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1902, Vol.94, Ko.12 1647 ciinton de Wentworth, contenant environ 100 acres et quelques bâtisses dessus érigées.Taxes h nieipales S20.34; intérêts: $1.53; frais d'avis et de recherches: $5.00.Total: $26.87.Marcel Desjardins, R.R.2, Lachute, Que.\u2014 l'n lopin de terre mesurant approximativement OU' x 100', avec bâtisses dessus éi igée, situé sur le lot 27A, rang 3, canton de Wentworth.Taxes municipales: $18.95; intérêts: $1.43; frais d'avis et .le recherches: $5.00.Total: $25.38.Mrs.L.a.Smart, adresse inconnue.\u2014 Un lopin de terre dont les dimensions sont décrites un bureau d'enregistrement d'Argenteuil dans les actes de vente portant les numéros 82104-82105 et N2I06, avec bâtisses dessus érigées, situé sur le lot originaire No 27a, rang 3, canton de Wentworth.Taxes municipales: $88.16; intérêts: 18.98; frais d'avis et de recherches: $5.00.Total: $102.14.Frederick Schmid, 900, rue Du lut h est, Mont-i«al.Que.\u2014 Lopin de terre avec bâtisses dessus érigées, situés sur le lot 27a rang 3, canton de Wentworth, et dont les descriptions sont données au bureau d'enregistrement d'Argenteuil, sous les numéros d'acte de vente: 67764.Taxes municipales: $82.18; intérêts: $8.08; frais d'avis et recherches: $5.00; taxes scolaires: $21.09.Total: $116.35.Warren F.Darch, adresse inconnue.\u2014 Un lopin de terre faisant partie du lot 23A rang 8, canton de Wentworth, mesurant 100 pieds des côtés nord et sud et 150 pieds des cotés est et oiie>t.borné au nord par le Lac Argenté, au sud.à l'est et à l'ouest par la propriété du vendeur, Georges Morrow ou ses représentants.Taxes municipales: $5.24; intérêts: $0.13; frais d'avis et recherches: $5.00; taxes scolaires: $5.08; intérêts et frais: $1.10.Total: $16.55.Laurel Enterprise, a/s R.Fandrich, 230, des Écores, Pont Viau, Que.\u2014 Lot 25A, rang 9, canton de Wentworth, mesurant approximative-ment 100 acres, tel qu'enregistré au bureau d'enregistrement d'Argenteuil, sous le numéro d'acte de vence, 96053.Taxes municipales: $10.00; intérêts: $1.19; frais d'avis et recherches: $5.00.Total: $22.19.Municipalité du village de Brownsburg \\ll>ert Perrier, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 758, rang 7, dans le village de Brownsburg, dans le canton de Chatham, bornée au nord par la rue Saint-Pierre, à l'est par F.Massie, au sud et à l'ouest par Georges Laçasse.Taxes munici-pales: $6.17.Total: $6.17.lîoma Renaud, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 754, rang 7, dans le village de Brownsburg, dans le canton do Chatham, bornée au nord par les \u2022i.emins de fer C.I.L.,à l'est par C.I.L., au sud par Noël Robillard, à l'ouest par la rue St-loseph.Taxes municipales: $140.02.Total: $140.02.Paul Guérard, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 758-54) rang 7, dans le village de Brownsburg, dans le canton de Chatham, bornée au nord par Mme Philippe Séguin, à l'est par la rue Saint-Juseph, au sud par O.Chàrlebois, â l'ouest par Hart land Dewar.Taxes municipales: $37.33.Total: $37.33.Artias Demers, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot SIS, rang 8, dans le village de Brownsburg, dans le canton de Chatham, bornée au nord par Réal Demers, à l'est par la rue du Couvent, au wd par C.Harding, à l'ouest par P.Turcot.Taxes municipales: $19.19.Total: $19.19.3, township of Wentworth, having an area of approximately 100 acres and with some buildings thereon erected.Municipal taxes: $20.34; interest: $1.53; notice and research costs: $5.00.Total: $26.87.Marcel Desjardins, R.R.2, Lachute, Que.\u2014 A strip of land measuring approximately 50' x 100' with a building thereon erected, situated on lot 27A, range 3, township of Wentworth.Municipal taxes: $18.95; interest: $1.43; notice and research costs: $5.00.Total: $25.38.Mrs.L.A.Smart, address unknown.\u2014 A strip of land the dimensions of which are described in the registry office of Argenteuil in the deeds of sale bearing the numbers 82104-82105 and 82106.with the buildings thereon erected, situated on original lot No.27a, range 3, township of Wentworth.Municipal taxes: $88.16: interest: $8.98; notice and reseurch costs: $5.00.Total: $102.14.Frederick Schmid, 900 Duluth Street east, Montreal, Que.\u2014 A strip of land with buildings thereon erected, situated on lot 27a.range 3, township of Wentworth, and the descriptions of which are given in the registry office of Argenteuil under the numbers of the deed of sale 67764.Municipal taxes: $82.18; interest: $8.08; notice and research costs: $5.00; school taxes: $21.09.Total: $116.35.Warren F.Darch, address unknown.\u2014 A strip of land forming part of lot 23A, range 8, township of Wentworth, measuring 100 feet on its north and south sides and 150 feet on its east and west sides, bounded on the north by Lac Argenté, on the south, the east and the west by the property belonging to the vendor, Georges Morrow or his representatives.Municipal taxes: $5.24; interest: $0.13; notice and research costs: $5.00; school taxes: $5.08; interest and costs: $1.10.Total: $16.55.Laurel Enterprise, c/o R.Fandrich, 230, des Écores, Pont Viau, Que.\u2014 Lot 25A, range 9, township of Wentworth, measui ing approximately 100 acres, as registered in the registry office of A men t eu il, under the number of the deed of sale, 96053.Municipal taxes: $16.00; interest: $1.19: notice and research costs: $5.00.Total $22.19.Municipality of the village of Brownsburg Albert Perrier, Brownsbrug.Que.\u2014 Pt.lot 758, range 7, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Saint-Pierre Street, east by F.Massie, south and west by Georges Laçasse.Municipal taxes: $6.17.Total: $6.17.Roma Renaud, Brownsburg, Que.\u2014 Pt.Jot 754, range 7, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by C.I.L.railroad, east by C.I.L., south by Noël Robillard, west by Saint-Joseph street.Municipal taxes: $140.02.Total: $140.02.Paul Guérard, Brownsburg, Que.\u2014 Pt.lot 758-54, range 7, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Mrs.Philippe Séguin, east by St.Joseph Street, south by O.Charlcbois, west by Hartland Dewar.Municipal taxes: $37.33.Total: $37.33.Artias Demers, Brownsburg.Que.\u2014 Pt.lot 818, range 8, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Real Demers, east by Couvent Street, sotuh by C.Harding, west by P.Turcot.Municipal taxes: $19.19.Total: $19.19. 1648 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tonu 94, No 12 Roméo Ducharme, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 819, rang 8, dans le village de Brownsburg, dans le canton de Chatham, bornée au nord par la rue Saint-Paul, à l'est par Conrad Lafleur, au sud par R.Turcot, à l'ouest par L.Paquette.Taxes municipales: $35.65.Total: $35 65.J.Marcel Parisien, Brownsbuig, Que.\u2014 P.lot 819, rang 8, dans le village de Brownsburg, dans le canton «le Chatham, bornée au nord par la rue Suint-Antoine, à l'est par la succession «le A.Germain Monette, au sud par Maurice Saint-Denis, à I'oiH'st par Jean Lys Neveu.Taxes municipales: $45.94.Total: $45.94.Léo Parent, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 818-4, rang 8, «lans le village de Brownsburg, dans le canton «le Chat haï».bornée au nord par Orner Danis, à l'est par C.Denis, au sud par 'a rue Des Pins, à l'ouest par la rue Saint-Louis.Taxes municipales: $83.53.Total: $83.53.Pierre St-Dcnis, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 818-1, rang 8, «lans le village «le Brownsburg, dans le canton «le Chatham, bornée au non! par Lauréat Ouelletle, à l'est pai C.I.L., au su«l par la rue Rose, à l'ouest par Oswald Neveu.Taxes municipales: $49.14.Total: $49.14.Kenneth Stewart, Brownsburg, Que.\u2014 P.lot 814, rang 8, dans le village de Brownsburg, dans le canton de Chatham, bornée au nord par W.Witham, à l'est par la rue Park, au sud par A.Campbell, à l'ouest par Maude Hazel.Taxes municipales: $3.23.Total: $3.23.Municipalité des Mille Iles M.George Schmidtler, adresse inconnue.\u2014 No cadastral P.lot 192, Côte Sainte-Marguerite, dans la municipalité des Mille Iles, bornée au nord par le lac Brâie (50 pieds «le front), bornée à l'ouest par la ligne de division entre les lots 192 et 193, à l'est et au sud par le reste du lot No 192, propriété de The Raymond Copping Estate.Au nord 50 pieds; au sud 75 pieds; à l'est 280 pieds; à l'ouest 280 pieds.Taxes municipales 1960, 1961.1962: $4.50; intérêt: $0.73; taxes scolaires 1959-60: $1.82; taxes scolaires: 1960-61: $2.15; taxes scolaires: 1961-62 $1.80; intérêt: $0.88.Total: $11.88.Municipalité du canton d'Arundel Succession Eleanor (Ellen) Noons, adresse inconnue.\u2014 Un certain morceau de terre, mesurant un acre carré, formant et étant partie du lot «le terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton d'Arundel, dans le comté d'Argenteuil, province «le Québec, comme partie du lot numéro trois (3) dans le premier rang dudit canton; ledit morceau de terre est situé à un acre à l'ouest «le la maison sur la propriété de Elijah Sims ou représentants, et est borné au sud par le chemin privé de Elijah Sims, et aux trois-autres côtés par le reste dudit lot numéro trois appartenant à Elijah Sims ou représentants.Avec le «Iroit d'utiliser en commun avec d'autres le droit de passage à pied et avec véhicules sur le chemin privé de Elijah Sims et représentants jusqu'au chemin public, et avec le droit de puiser «le l'eau du puits dudit Elijah Sims et représentants jusqu'à ce qu'une provision d'eau puisse être obtenu sur la propriété ci-haut décrite.Taxes scolaires: $19.28; intérêt: $1.05; taxes municipales: $38.38; intérêt: $6.05.Total: $64.76.Municipalité du village d'Ayersville J.Mcndoza Gauthier, R.R.2, Lachute, Que.\u2014 Partie de lot No 649, 50* x 100' donnant sur la rue Roméo Ducharme, Brownsburg, Que.\u2014 Pt.lot 819, range 8, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Saint-Paul Street, east by Conrad Lafleur, south by II.Turcot, west by L.Paquette.Municipal taxes: $35.65.Total: $35.65.J.Marcel Parisien, Brownsburg, Que.-Pt.lot 819, range 8, in the village of Browsnbmg, in the township of Chat ham, bounded north by Saint-Antoine Street, east by estate of A.Germain Monette, south by Maurice Saint-Denis, west by Jean Lys Neveu.Municipal taxes: $45.94.Total! $45.94.Léo Parent, Brownsburg, Que.\u2014 Pt.lot 818-4, range 8, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Omer Danis, east by C.Denis, south by Des Pins Street, west by Saint Louis Street.Municipal Taxes : $83.53.Total : $83.53.Pierre St.Denis, Brownsburg, Que.\u2014 Pt.lot 818-1, range 8, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, bounded north by Lauréat Ouellette, east by C.I.L., south by Rose Street, west by Oswald Neveu.Muuitipul taxes: $19.14.Total: $49.14.Kenneth Stewart, Brownsburg, Quebec.\u2014 Pt.lot 814, range 8, in the village of Brownsburg, in the township of Chatham, north by W.Witham, cast by Park Street, south by A.Campbell, west by Maude Hazel.Municipal taxes: $3.23.Total: $3.23.Municipality of Mille Isles Mr.George Schmidtler, address unknown.\u2014 Cadastral No.Pt.lot 192, Côte Sainte-Marguerite, in the municipality of Mille Isles, bounded on the north by I,ac Bexie (50 feet frontage), bounded to the west by the divisional line between lots 192 and 193 to the east and south by the remainder of lot No.192, the property of The Raymond Copping Estate.To the north 50 feet; to the south 75 feet; to the east, 280 feet; to the west, 280 feet.Municipal taxes 1900, 1961, 1962: $4.50; interest: $0.73; school taxes 1959-1960: $1.82; school taxes 1960-1961: $2.15; school taxes: 1961-1962: $1.80; interest: $0.88.Total: $11.88.Municipality of the township of Arundel Estate Eleanor (Ellen) Noons, address unknown.\u2014 A certain parcel of land, measuring one acre square, forming and being a part of the lot of land known and designated on the official plan and in the book of reference of the township of Arundel, in the county of Argenteuil, Province of Quebec, as part lot number three (3) in the first range of said township; the said parcel of land is situated one acre west of the house on the property of Elijah Sims or representatives, and is bounded to the south by Elijah Sims' private road, and on the other three sides by the remainder of the said lot number three belonging to Elijah Sims or representatives.With the right of use in common with others of the right of way on foot and with vehicles over the private road of Elijah Sims and representatives to the public road, and with the right to take water from the well of the said Elijah Sims and representatives until such time as a water supply can be obtained on the property herein above described.School taxes: $19.28; interest: $1.05; municipal taxes: $38.28; interest: $6.05.Total: $64.76.Municipality of the village of Ayersville J.Mendoza Gauthier, R.R.2, Lachute, Que.\u2014 Part of lot No.649, 50' x 100', bordering on QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 Bradford*4*0* le village d'Ayersville du eadastie officiel du canton de Chatham, borné au sud par un lot appartenant à M.Alfred Campeau, à l'ouest par un lot appartenant à M.Ovila Debien, an nord par un lot appartenant a M.Olier Hooper et à l'est par la rue Bradford.Taxes municipales: $120.48; taxes scolaires: $32.57.Total: $159.05.Lucien Gagné, 244, rue Champlain, Ayersville, Que.\u2014 Partie du lot No 049, 50' x 100', donnant sur la nie Champlain, dans le village d'Ayeisville du cadastre officiel du canton de Chatham, borné au nord par un lot appartenant à M.Hilaire I).-lauriers, au sud par un lot appartenant à M.OH a vins Bruce, à l'ouest par le lot 651 ou Douglas d.Simon et à l'est par la rue Champlain.Taxes municipales: $10.40; taxes scolaires: $35.82.Total: $46.22.Claude I/urocque, 77, rue Ayers, Ayersville, Que.- Partie du lot No 649, 50' x 100' donnunt sur la rue Ayers, dans le village d'Aycrsville du cadastre officiel du canton de Chatham, borné au nord par une partie du lot 649 propriété «le Dominion Ayers Wood Co., au sud par la rue \\v -, à l'ouest par un lot appartenant à M.Allied Campeau et au nord par un lot appartenant à M.Alfred Tassé.Taxes municipales: $5.00: taxes scolaires: $32.57.Total: $37.57.M.Albert Le may, 78, nie Chatham, Ayersville, Que.- Partie du lot No 648, subdivision 190, 50' x 100' donnant sur la rue Chatham, «lans le village d'Ayersvillc du ca«lastre officiel du canton de Chatham, borné au nord par la rue Chatham, à l'ouest par la propriété «le M.Euclide Desforges (648-189), au sud par la propriété de M.John Deschamps (648-176), et à l'est par la rue Corbeil.Taxes municipales: $163.80; taxes scolaires: $320.17.Total: $483.97.Municipalité du village de Saint-André Est Succession Josaphat Laliberté, rue Wales, Saint-André Est, Que \u2014P.lot 399, dans la municipalité du village de Saint-Andié Est, dans la paroisse de Saint-André, une forme irrégulière bornée au nord par 394, au sud par 406, à l'est par 400, et à l'ouest par 395 et 398, appartenant à la succession de J.Laliberté, rue Wales.Taxes municipales: $67.15.Total: $67.15.Succession Wright, rue Saint-André Ouest.\u2014 P.lot 105, dans la municipalité du village de Saint-André Est, dans la paroisse de Saint-André, bornée au nord-est par 106, au su«l-ouest par 104, au nojd-ouest par 142, et au sud-est par 88, et appartenant à la succession de Mme Wright.Taxes municipales: $89.76.Total: $89.76.Corporation du Lac des Seize Iles dans le canton de Montcalm et le canton de Wentworth René Fandrich, 230 boulevard des Écores, Pont-Viau,' Que.\u2014 Partie du lot numéro 246 dans ledit neuvième rang, dans la Corporation du Lac des Seize Iles, canton de Wentworth, continue à la partie du lot numéro vingt-cinq a Ci-haut décrite vers l'ouest (exception des deux petites lisières de terre vendues à James Ainslie et messieurs Lapierre et Raymond) et laquelle partie du lot numéro 246 présentement vendue, avec les lisières de terre extraites susdites, est borné comme suit: vers le nord, partie par une autre partie dudit lot numéro 246 appartenant a (îiiillaume Boivin ou ses représentants, partie Bradford Street, in the village of Ayersville in the official cadaster of the township of Chatham, bounded on the south by a lot belonging to Mr.Alfred Campeau, on the west by a lot belonging to Mr.Ovila Debien, on the north by a lot belonging to Mr.Olier Hooper and on the east by Bradford Street.Municipal taxes: $126.48; school taxes: $32.57.Total: $159.05.Lucien Gagné, 244, Champlain Street, Ayersville, Que.\u2014Part of lot No.649, 50' x 100', bordering on Champlain Street, in the village of Ayersville, in the official cadaster of the township of Chat ham, bounded on the north by a lot belonging to Mr.Hilaire Deslauriers, on the south by a lot belonging to Mr.Octavius Bruce, on the west by lot 651, or the land belonging to Douglas G.Simon, and on the east by Champlain Street.Municipal taxes: $10.40; school taxes: $35.82.Total: $46.22.Claude Larocque, 77, Ayers Street, Ayersville, Que.\u2014Part of lot No.649, 50' x 100', bordering on Ayers Street, in the village of Ayersville in the official ca«laster of the township of Chatham, bounded on the north by a part of lot 649, property of Dominion Ayers Wood Co., on the south by Ayers Street, on the west by a lot belonging to Mr.Alfred Campeau, an«l on the north by a lot belonging to Mr.Alfred Tassé.Municipal taxes: $5.00; School taxes: $32.57.Total: $37.57.Mr.Albert Lemay, 78, Chatham Street, Ayersville, Que.\u2014 Part of lot No.648, subdivision 190, 50' x 100', bordering on Chatham Street, in the village of Ayersville in the official cadaster of the township of Chatham, bounded on the north by Chatham Stieet, on the west by the property of Mr.Euclide Desforges (648-189), on the south by the property of Mr.John Deschamps (648-176), and on the east by Corbeil Street.Municipal taxes: $163.80; school taxes: $320.17.Total: $483.97.Municipality of the village of Saint-André East Estate Josaphat Laliberté, Wales Street, Saint-André East, Que.\u2014 Pt.lot 399, in the municipality of the village of Saint-André East, in the parish of Saint-André, an irregular figure bounded on the north by 394, on the south by 406, on the east by 400, and the west by 395 and 398, owned by the estate of J.Laliberté, Wales Street.Municipal taxes: $67.15.Total: $67.15.Estate Wright, Saint-André West, Street.\u2014 Pt.lot 105, in the municipality of the village of Saint-André East, in the parish of Saint-André, bounded on the northeast by 106, on the southwest by 104, on the northwest by 142, and on the southeast by 88, and owned by the estate of Mrs.Wright.Municipal taxes: $89.76.Total: $89.76.Corporation of Sixteen Island Lake in the township of Montcalm and township of Wenworth René Fandrich, 230, des Écores Boulevard, Pont-Viau, Que.\u2014 Part of lot number 246 on said ninth range, in the Corporation of Sixteen Island Lake, township of Wentworth, adjoining the part of lot number twenty-five a described above on the west (with the exception of the two small strips of land sold to James Ainslie and Messrs Lapierre and Raymond) and which part of lot number 246 presently sold, with the strips of land withdrawn above, and bounded as follows: on the north, partly by another part of said lot number 246 belonging to Guillaume Boivin or his representatives, partly by Sixteen 1650 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 man 1962, Tome 94, No 12 par le Lac des Seize Iles, partie par une autre partie dudit lot numéro vingt-quatre B vendue à Albert Cook ou représentants et partie par une autre partie dudit lot numéro 246 vendue audit Alcock, ou représentants, vers le sud partie par le lac Long et partie par la ligne de division entre les huitième et neuvième rang dudit canton Wentworth, vers l'ouest, par partie dudit numéro vingt-cinq a présentement vendue et ci-haut décrite et vers l'est, partie par le lac Des Seize Iles et partie par ladite partie dudit lot numéro 246 appartenant à Guillaume Boivin ou représentants et partie par le Lac Long et partie par le lot numéro 24a dans ledit neuvième rang.Taxes municipales: 1961 : $74.25; taxes municipales: 1962: $71.75; Intérêt: $9.40; taxes scolaires: 1961-62: $79.20; taxes scolaires: 1960-61 : $99.00; taxes scolaires: 1959-60: $11.19; intérêt: $3.97: agrandissement: 0.25 par 100: $24.75.Total: $373.51.John Nehrer.800 ouest, Jairy, Montréal, Que.\u2014 Un certain emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dans la Corporation du Lac des Seize Iles dans le canton de Wentworth, comme formant partie du lot numéro vingt-trois dans le neuvième rang (P.23 rang IX) mesurant aux lignes nord et sud deux cents pieds (200 pieds) aux lignes est et ouest par une profondeur pouvant être trouvée entre le chemin public et la propriété de l'acheteur, borné au nord par le chemin public, au sud sur une distance de deux cents pieds (200 pieds) par l'acheteur, à l'est par la propriété de Julien Milette, à l'ouest par la propriété de G.Millette sans bâtisses.Toutes mesures anglaises plus ou moins.Comme ladite propreté subsiste présentement avec les servitudes actives et passives y attachées.Taxes scolaires 1961-62: $21.60; taxes scolaires 1960-61: $27.00; taxes scolaires 1959-60: $2.71; intérêt: $1.05; obligations 0.25 par 100: $6.75.Total: $59.11.Pau Dion, 7392, Saint-Denis, Montréal, Que.\u2014 Un emplacement situé dans le premier rang de la Corporation du Lac des Seizes Iles, du canton Montcalm comté d'Argenteuil connu et désigné comme faisant partie du lot numéro trente-quatre (P.No 34) dudit rang, au plan et livre de renvoi officiel du canton Montcalm.De la contenance de cent quinze pieds (115') de front par cent cinquante pieds (150') de profondeur, borné comme suit: au nord par la ligne de division entre les premier et deuxième rang dudit canton Montcalm, à l'arrière vers le sud par un emplacement appartenant à Raoul Lamar-che, d'un côté vers l'est par le terrain de la fabrique de la paroisse du Lac des Seize Iles, et de l'autre côté vers l'ouest par la propriété de Monsieur Patterson.Taxes scolaires 1961-62: $12.00; taxes scolaires 1960-61: $15.00; taxes scolaires 1959-60: $15.00; taxes scolaires 1958-59: $12.00; intérêts: $3.91; frais: $0.50; obligations: 0.25 par 100: $3.75.Total: $62.16.Gilles Marsolais, 2430, rue Saint-Antoine, Montréal, Que.\u2014 De la moitié ouest du lot numéro trente-trois du premier rang dans la Corporation du Lac des Seize Iles, au cadastre du canton Montcalm mesurant quatre cent vingt-neuf pieds de largeur sur toute la profondeur dudit lot; borné au nord par la ligne de division entre le premier rang et le deuxième rang d'un côté; à l'ouest par le lot numéro 32 du premier rang, en arrière au sud par la ligne de division entre le canton Montcalm et le canton Wentworth, et de l'autre côté à l'est partie par la partie de la moitié est du lot 33 ci-après désigné et partie par le résidu dudit lot No 33.Island Lake, partly by another part of saui number twenty-four 6 sold to Albert Cool representatives and partly by another par said lot number 246 sold to said Alcock or re sentatives, on the south partly by Lac Long partly by the division line between the ei{ and ninth ranges in said township of Went w a on the west by part of said lot twenty-ii\\ presently sold and described above, and on east, partly by Sixteen Island Lake and pa by said part of said lot number 246, beloui to Guillaume Boivin or representatives and pa Lac Long, and partly by lot number 24a on ninth range.Municipal taxes: 1961: $71 Municipal taxes: 1962: $71.75; interest: $£ school taxes: 1961-62: $79.20; school ta 1960-61: $99.00; School taxes: 1959-60: $11 interest: $3.97; annex: 0.26by 100: $24.75.T< $373.51.John Nehrer, 800, Jarry West, Mon;: Que.\u2014 A certain emplacement known designated on the official plan and in the 1 of reference in the Corporation of Sixteen Isl Lake in the township of Wentworth, as forn part of lot number twenty-three in the a range (Pt 23 range IX) measuring on the in and south lines two hundred feet (20(1 '< east and west lines by the depth which mighl found Let ween the public road and the profx of the purchaser, bounded north by the pu road, south on a distance of two hundred (200 feet) by the purchaser, east by ,lu Millette's property, west by G.Millette | perty without buildings.All English nice more or less.As the said property now subi with the active and passive servitudes thei attached.School taxes: 1961-62: $21.60; sef taxes: 1960-61: $27.00; school taxes: 1959 $2.71; interest: $1.05; obligations 0.25 per 1 $6.75.Total: $59.11.Paul Dion, 7392, Saint-Denis, Montr Que.\u2014 An emplacement situated on the I range of the Corporation of Sixteen Island U iii the township of Montcalm, county of Arf teuil, known and designated as forming pari lot number thirty-four (Pt 34) on said range the official plan and book of reference for township of Montcalm, measuring one luind and fifteen feet (115') in front by one hund and fifty feet (150') in depth, bounded as folio on the north by the division line between first and second ranges in said township Montcalm, in the rear on the south by an em] cement belonging to Raoul I^amarche, on > side on the east by the land belonging lo fabrique of the parish of Sixteen Island Lake, : on the other side on the west by the propcrtj Mr.Patterson.School taxes: 1961-62: ?I2.school taxes: 1960-61: $15.00; school tai 1959-60: $15.00; school taxes: 1958-59: $12.interest: 13.91; costs: $0.50; obligations: 0 25 100: $3.75.Total: $62.16.Gilles Marsolais, 2430, Saint-Antoine Stn Montreal, Que.\u2014 The west half of lot numl thirty-three on the first range in the Corporat of Sixteen Island Lake, in the cadaster of township of Montcalm, measuring four hund and twenty-nine feet in width by the entire del of said lot, bounded on the north by the divii line between the first range and the second rai on one side, on the west by lot number 32 on I first range, on the rear on the south by ' division line between the township fo Montes and the township of Wentworth, and on the otl side by the part of the east half of lot 33 herein ter designated and partly by the remainder said lot No.33. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1902, Vol 94, No.12 11 D'une partie de la moitié est du lot No 33 du premier rang dans la Corporation du Lac des Seize Iles, du canton Montcalm, l>orné au nord au 2e rang, d'un coté à l'ouest par une partie de la moitié ouest dudit lot No 33 ci-dessus désigné, en arrière au sud par le résidu dudit lot No 33 appartenant à Dame Wallace K.Henry ou repré-¦entantftj et de l'autre côté à l'est par le lot No 34 du i et rang du même cadastre./; De l'extrême partie sud est du lot No 33 du 1er rang dans la Corporation du Lac des Seize Ilr-, du canton Montcalm mesurant 296 pieds de largeur dans sa limite sud, et borné au nord par mu autre partie dudit lot No 33 appartenant à Dame W.IL McManus ou représentants, d'un côte à l'ouest par une partie de la moitié ouest dudil lot No 33, an arrière au sud par lu ligne de division entre le canton Montcalm et le canton Went worth à l'ouest par une partie du lot No 27.au sud par le residue dudit lot No 26 et de l'autre côté à l'est par le Lac dos Seize Iles.'/ I >'une partie du lot No 26 du onzième rang dans la Corporation du Lac des Seize Iles, du cant \u2022 >n Wentworth, mesurant 390 pieds de largeur mesure anglaise, du nord au sud sur toute la l>: udeur qu'il y a entre le Lac des Seize Iles et le lot No 27 dudit cadastre, et borné au nord par la ligne de division entre le canton Montcalm et I' ¦ .mton Wentworth, à l'ouest par une partie du lot No 27, au sud par le résidu dudit lot No 26, et de l'autre côté à l'est par le Lac «les Seize Iles.h) D'une partie de lot No 26 du Xle rang dans la Corporation du Lac des Seize Iles, du canton Wentworth, mesurant 150 pieds de largeur sur toute la profondeur qu'il y a entre la li^-ile de division du lot No 26 et du lot No 27 et la partie du No 26, ci-après «lésignée, borné au nord par une partie de la partie du lot No 26 ci-dessus désigné d'un côté à l'ouest par une partie du lot No 27 en arrière au sud par le résidu «ludit lot No 26 et de l'autre côté à l'est par la partie du lot No 26 ci-après désignée.i1 D'une partie du lot No 26 du Xle rang dans la ( orporation du Lac des Seize Iles, du canton Wentworth, contenant 75000 milles pieds carrés «!«¦ superficie, ladite partie devant être mesurée à partir d'un point situé à une distance de 390 pieds au sud de la ligne de division entre le canton Wentworth, d'une distance de 150 pieds dans la «lireetion sud sur une profondeur de 500 pieds ans le canton de Lahrccque: Les lots 33 à 47 inclusivement du rang VIII; 31 à 36 inclusivement du rang IX; 31 à 33 inclusivement du rang X.Dans le canton de Rouleau: Les Blocs « A ».« B », « C » et «D »; les lots 1 à 19 inclusivement du rang A; 20 et 21 du rang ouest du Lac des Habitants; 17 à 22 inclusivement du rang Est du Lac «les Habitants; 1 à 4 inclusivement du rang C.4° Dans le canton de Jogucs: Les lots 22 à 37 inclusivement du rang I: 18 à 50 inclusivement du rang II ; 16 à 22 inclusivement et 48 à 73 inclu-¦ivement du rang III; 10 à 15 inclusivement et 49 à 72 inclusivement du rang IV; 3 à 8 inclusivement et 52 à 72 inclusivement du rang V; « A », « B h et 1 à 8 inclusivement du rang VI; « B » et t c \u2022 du rang VII.5° Duns le canton de Milot: Les lots 1 à 7 inclusivement du rang I; 1 à 3 inclusivement du rang IL 6 Dans les parties non subdivisées des cantons de Bouleau, Jogucs, Maltais, Constantin et Sl-Ongc et du comté de Chicoutimi, une lisière d'un mille de chaque côté du lac Tchitugamu et de la rivière Péribonka à partir de la limite nord du canton de Labrecque jusqu'à la limite nord du canton de St-Onge.7° Dans le canton de Taillon: Les lots 29 et 30 du rar-g VII, 15 à 26 inclusivement du rang VIII; 18 à 2'.i inclusivement du rang IX; 19 à 29 inclu-sivemci t du rang X ; 24 à 29 inclusivement du rang XI; 4 à 27 inclusivement du rang-XII.6 Dans le canton de Dalmas: Les lots 69 à 71 inclusivement du rang III; 66 à 71 inclusivement du rang IV; 66 à 71 inclusivement du rang VII; 62 à 71 inclusivement du rang VIII; 64, 65 et 69 à SI inclusivement du rang IX.le tout en conformité des dispositions de l'article 227 de la Loi des mines de Québec (S.R.Q., 1941, Chapitre 196); Attendu que lesdits terrains avaient été ainsi soustraits au jalonnement en claims miniers dans le but de fermer à la prospection une étendue de territoire susceptible d'être submergée par suite de la construction d'un barrage sur la rivière Péribonka par l'Aluminium Company of Canada.Limited; Attendu que, conformément aux dispositions de la Ix>i 14 George VI, chapitre 60, certains terrains ont été concédés par contrat à la compagnie susdite en bordure «le la rivière Péribonka aux Rus d'ériger ledit barrage; Attendu que l'érection dudit barrage est nia in tenant complétée et que les terrains ayant fait l'objet de la soustraction au piquerage mis en force par les arrêtés en conseil No 869 du 8 août 1951, No 1139 du 10 octobre 1951 et No 1311 du 29 novembre 1951, ci-dessus n'ayant pas tous été submergés par le refoulement des eaux, \u2022j y aurait lieu de réouvrir à la prospection ces étendues de terrain non submergées sous réserve cependant des dispositions de l'article 33 de al Whereas pursuant to the Orders in Council No.869 of August 8, 1951, No.1137 dated October 10, 1951 and No.1344 dated November 28, 1951, published in the Quebec Official Gazette on August 18, October 20 and December 7, 1951, certain lots of land situuted in the townships of (îarnier, Jogucs and Tuillon, electoral district of Luke St.John; Luhrccepic and Rouleau, electoral district of Jonquière-Kénogami; Milot and Dalmas, electoral district of Roberval, have been withdrawn from stuking of mining claims, to wit: 1.In the township of Gurnier: Lots 42 to 49 inclusively on range I; 1 to 9 inclusively on range II; 5 to 12 inclusively and 32 to 39 inclusively on range III ; 11 to 34 inclusively on runge 1V.2.In the township of Labrecque: Lots 33 to 47 inclusively on Range VIII; 31 to 36 inclusively on range IX; 31 to 33 inclusively on range X.3.In the township of Rouleau: Blocks \"A\", \"B\", \"C\" and \"D\"; lots 1 to 19 inclusively on range A; 20 and 21 on the West Range of Lac des Habitants; 17 to 22 inclusively on the East Range of Lac «les Habitants; 1 to 4 inclusively on range C.4.In the township of Jogucs: Lots 22 to 37 inclusively on range I; 18 to 50 inclusively on range II; 16 to 22 inclusively and 48 to 73 inclusively on range III; 10 to 15 inclusively and 49 to 72 inclusively on range IV; 3 to 8 inclusively and 52 to 72 inclusively on range V: \"A\", \"B\" and 1 to 8 inclusively on range VI; \"B\" and \"C\" on range VII.5.In the township of Milot: Lots 1 to 7 inclusively on range I; 1 to 3 inclusively on range II.6.In the unsubdivided parts of the townships of Rouleau, Jogucs, Maltais, Constantin and St-Onge and in the county of Chicoutimi, a strip of one mile on each side of lake Tchitagama and of the Péribonka River starting from the north boundary of the township of Labrecque as far as the north boundary of the township of St-Onge.7.In the township of Taillon: Lots 29 and 30 on range VII, 15 to 26 inclusively on range VIII; 18 to 23 inclusively on range IX; 19 to 29 inclusively on range X; 24 to 29 inclusively on range XI; 4 to 27 inclusively on range XII.8.In the township of Dalmas: Lots 69 to 71 inclusively on range III; 66 to 71 inclusively on range IV; 66 to 71 inclusively on range VII; 62 to 71 inclusively on range VIII; 64, 65 and 69 to 81 inclusively on range IX.the whole in conformity with the provisions of section 227 of the Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, chapter 196); Whereas the said terrains had been thus withdrawn from staking of mining claims for the purpose of closing to prospection a stretch of territory susceptible to submersion following the construction of a dam on the Péribonka River by the Aluminum Company of Canada, Limited; Whereas pursuant to the provisions of Act 14 George VI, chapter 60, certain lots of land were conceded by contract to the above-mentioned Company on the bank of the Péribonka River for the purpose of erecting said dam ; Whereas the erection of the said dam has now been completed and that the terrains which were the object of the withdrawal from pegging, put into force by the Orders in Council No.869, dated August 8,1951, No.1139, dated October 10, 1951 and No.1344 dated November 29, 1951, above, not all having been submerged by the stemming of the waters, it is expedient to re-open to prospection these stretches of unsubmerged land, under reserve, however, of the provisions 1054 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tonus 94, No 12 lx)i des mines de Québec quant aux terrains ou IMillions de terrains concédés à ladite compagnie; Aitkn ni yi.io l'article 227 de la Loi des mines de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 190) autorise le lieutenant-gouverneur dn conseil à faire tout règlement qu'il juge nécessaire ou convenable, concernant la soustraction au piquetage de certains.Il kst on ix).n m':, en conséquence, sur lu proposition du Ministre des richesses naturelles: Quk le règlement suivant soit adopté et, après son adoption, qu'il soit publié dans la Gazette Officielle de Quclxc; Quk les terrains ou parties de terrains non submergés par suite «le l'érection d'un barrage sur la rivière Péribonka à la Chute du Diable par l'Aluminum Company of Canada, Limited, et qui ont été soustraits au piquetage par les arrêtés en conseil No 809 du 8 août 1901.No 1137 du 10 octobre 1951 et No 1344 du 29 novembre 1951, soient réouverts à la prospection et au jalonnement eu daims miniers sous réserve, cependant, des dispositions de l'article 33 de la Loi des mines de Québec (S.R.Q., 1941.chapitre 190) 196) quant aux terrains ou portions de terrains concédés à l'Aluminum Company of Canada.Limited.Jacques Prémont, 60756-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 388 Section « E » Québec, le 13 mars 1962.Présent: Le lieutenant -gouverneur en conseil.Concernant un amendement au règlement de prélèvement du Comité Conjoint des Coiffeurs de Drummond ville.Il kst ordonne, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Quk le règlement de prélèvement du Comité Conjoint des Coiffeurs de Drummond ville, approuvé par l'arrêté en conseil numéro 103 du 24 janvier 1962, section « B », soit modifié comme suit: Le paragraphe c) de l'article I (Cotisation) est radié et remplacé par le suivant: « c) Les artisans assujettis audit décret numéros 2468 doivent verser au Comité paritaire les sommes suivantes : i.Les artisans barbiers, coiffeurs et coiffeuses pour dames de la Zone I.$0.30 par semaine.ii.Les artisans barbiers, coiffeurs et coiffeuses pour dames de la Zone II-$0.25 par semaine.Tout employeur ou employeur professionnel qui pratique lui-même un métier ou une profession régis par le décret numéro 2468, est, de plus, considéré aux fins du présent règlement, comme un artisan.» Jacques Prémont, 60757-o Greffier Adjoint du Conseil exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 388 Section « G » Québec, 13 mars 1962.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un amendement au décret relatif aux barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans la région de Sherbrooke.of section 33 of the Quebec Mining Act, us tu the terrains or portions of land conceded to said Company; Whereas section 227 of tlte Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, chapter 196) authorize the Lieutenant-Governor in Council to pass any by-law which he judges necessary of convenient, concerning the withdrawal from pagging of certain lauds.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Natural Resources: That the following by-law be adopted and, after its adoption, that it be published in the Quebec Official Gazette; That the terrains or parts of land not submerged following the erection of a dam on the Péribonka River at Chute du Diable by the Aluminum Company of Canada, Limited\", and which were withdrawn from pegging by Orders in Council No.869, dated August 8, 1961, No.1137 dated October 10, 1951 and No.1344 dated November 29, 1951, be re-opened to prospection and to staking of mining claims, under reserve, however, of the provisions of section 33 of the Quebec Mining Act (R.S.Q.1941, chapter 196) as to the terrains or parts of land conceded to the Aluminum Company of Canada, Limited.Jacques Prémont, 60756 Deputy Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 388 Section Quebec, March 13, I962.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the levy by-la* of the Joint Committee of Hairdressers of Drummond ville It is ordained, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That the levy by-law of the Joint Commit tee of Hairdressers of Drummondville, approved by Order in Council number 103 of January 24, 1962, section \"B\", be amended as follows: Paragraph e) of article I (Levy) is d< leted and replaced by the following: \"c) Artisans governed by the said décret number 2468 shall pay to the Parity Committee the following sums: i.Barbers, male and female hairdresser! artisans of Zone I.$0.30 per week.ii.Barbers, male and female hah du-sers artisans of Zone II.$0.25 per week.Every employer or professional employer who plies a trade or a profession governed by the decree number 2468, is considered, for tin purposes of the present by-law, as an artisan.\" Jacqlks Prémuni.60757-o Deputy Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 388 Section \"G\" Quebec, March 13, 1962.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the decree relating to barbers and hairdressers in the region of Sherbrooke. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, So.12 1055 \\ i iKndu quk, conformément aux dispositions di concernant l'assistance aux mères néces- siteuses.\u2022 2 Loi modifiant la Loi de l'Office du crédit agricole du Québec.13 Loi relative aux concours artistiques, littéraires et scientifiques.18 Loi concernant la probité duns l'administra- tion des commissions scolaires.19 Loi modifiant la Loi des pensions.20 Ix)i concernant la Sûreté provinciale du Québec.fixed at three (3) years from and after the following elections which are to take place on the first judicial Monday of November, 1902.Wheheas the term office of the Mayor and the Aldermen fixed at three (3) years, will be a guarantee of the stability of the administration of municipal affairs of the Town of Auteuil; Whereas the Council muy, by by-law, fix such a term: He it adjudicated, ordained, decreed and ordered, by by-law of the council of the Town, and it is by the present by-law adjudicated, ordained, decreed and ordered, subject to all the approvals requirtd by law, as follows: Section I: The council does hereby fix at three (3) years, from and after the following general elections, the term of office of the Mayor and Aldermen.Section 11: The said by-law must be upproved by the Lieutenant-Governor in Council and be published in the Quebec Official Gazette.Section III: The present by-law will enter into force according to law.Ronald Bouhcter.Secretary- Treasurer 00782-12-2 of the Town of A uteuil.Bills \u2014 Legislative Assembly Legislative Council Chamber Quebec, 14th of March, 1962., This day, at fifteen minutes past five o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor proveeded to the legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 3 An Act to amend the Industrial Funds Act.4 An Act to amend a grant to Sir George Williams University.5 An Act to assist the establishment of young farmers.6 An Act to amend the Agricultural Abuses Act.9 An Act to establish the Department of Agriculture and Colonization.10 An Act to establish the Department of Game and Fisheries.11 An Act respecting assistance to needy mothers.12 An Act to amend the Act respecting the Quebec Farm Credit Bureau.13 An Act respecting artistic, liter.-.ry and scientific compel it ions.IS An Act respecting probity in the administration of school boards.19 An Act to amend the Pension Act.20 An Act respecting the Quebec Provincial Police Force. 1668 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 man 1962, Tonus 94, No 12 23 Loi concernant le budget de la cité de Montréal.109 l*oi constituant en corporation I*es Frères du Sacré-Cœur.113 Loi concernant deux donations entrevifs de Arthur Décary.120 Loi relative à la succession de Joseph- Alexandre Yiuu.121 Loi concernant l'Église mention i te et la Conférence canadienne de l'Église des Frères mennonites de l'Amérique du Nord.124 Loi constituant en corporation The Re-constructionist Synagogue of Montreal.126 Loi autorisant le Barreau «le la province de Québec à admettre Pierre Claude Founder à l'exercice «le la profession «l'avocat «lans la province «le Québec.136 Loi changeant le nom de Michael Perelstein en celui «le Michael Perelstein Marchand.148 Loi relative à la Société d'administration et de fiducie.156 Loi changeant le nom de Thérèse Couturier en celui «le Thérèse Gendreau.165 Loi changeant le nom de Joseph Henri Georges Léon Raphaël Rousseau en celui de Joseph Léon Henri Benoît.173 Loi concernant Young Israel of Val Royal.195 Loi changeant le nom de Samuel Lion Simak en celui de Lionel Schwartz.199 Loi concernant The Congregation Beth Hamedrash Hagadol.204 Loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre Laszlo Szemenyei à l'exercice de la profession d'avocat dans la province de Québec.206 Loi changeant le nom de Antoine Êlie Paul Dupré en celui de Léo Dupré.207 Loi constituant en corporation The Evan- gelical Free Church of America in the Province of Quebec.208 Loi constituant en corporation Anshei Ozeroff Congregation.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.» 24 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1962, et pour d'autres fins.A ce bill, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses fidèles sujets, agrée leur benevolence et sanctionne ce bill.» 60763-O 23 An Act respecting the budget of the city of Montreal.109 An Act to incorporate Les Frères du Sacre -Cœur.113 An Act respecting two gifts inter vivos of Arthur Décary.120 An Act respecting the estate of Joseph- Alexandre Viau.121 An Act respecting The Memionite Church and the Canadian Conference of the Men-nonite Brethren Church of North America.124 An Act to incorporate The Reconstruct ion ¦ i Synagogue of Montreal.126 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Pierre Claude Four nier to the practice of law in the Province of Quebec.136 An Act ot change the name of Michael Perelstein to that of Michael Perelstein Marchand.148 An Act respecting the Administration and Trust Company.156 An Act to change the name of Thérèse Couturier to that of Thérèse Gendreau.165 An Act to change the name of Joseph Henri Georges Léon Raphaël Rousseau to that \u2022 f Joseph Léon Henri Benott.173 An Act respecting Young Israel of Val Royal.195 An Act to change the name of Samuel Lion Simak to that of Lionel Schwartz.199 An Act respecting The Congregation Beth Hamedrash Hagadol.204 An Act to authorize the Bar the Province of of Quebec to admit Laszlo Szemenyei to the practice of the legal profession in the Province of Quebec.206 An Act to change the name of Antoine Klie Paul Dupré to that of Léo Dupré.207 An Act to incorporate The Evangelical Free Church of America in the Province of Quebec.208 An Act to incorporate Anshei Oseroff Con- gregation.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council in the following words: \"In Her Majesty's name, the Honourable tlie Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 24 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March 1962, and for other purposes.To this bill the Royal assent was signified in the following words : \"In Her Majesty's name the Honourable the Lieutenant-Governor thanks her loyal subjects accepts their benevolence and assents to this bill.\" 60763-O QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Val.94.No.12 Compagnies autorisées à faire des affaires Great Lake* Investment Co.Limited Avis est donne que la compagnie « Great Lakes Investment Ca>.Limited », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de la province d'Ontario, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, confoimé-.lient aux dispositions de la Loi des Sociétés de Prêta et de Placements.S.R.Q., 1941, chapitre 288.Le bureau principal de ladite compagnie dans ia province sera établi à 901, carré Victoria, en lea cité et district judiciaire de Montréal.Son agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre elle est M.Donald James Johnston, a vim at, de ladite cité de Montréal.Montréal, P.Q.ce 7e jour de mars 1962.L'Agent principal, '')652-10-4 Donald James Johnston.Union Finance Company Limited Avis est donné qu'une autorisation a été accordée, en date du 14 février 1962, à la compagnie « Union Finance Company Limited », conformément aux dispositions de la Loi des sociétés de prêts et de placements, autorisant ladite compagnie à exercer son commerce dans la province de Québec.Daté à Montréal, P.Q.ce 8e jour de mars 1088.L'Agent principal, 60718-11-4 M.G.ÀNotm.Allstate Enterprises, Inc.Avis est donné que « Allstate Enterprises, Inc.», une compagnie à fonds social étrangère constituée en corporation en vertu des lois de l'État du Delaware, E.U.A., a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi \u2022 les compagnies à fonds social étrangères, statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 279.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre \u2022 Ile, est M.L.G.Hosier, de 2360 chemin Lucerne, M ont-Royal.Le bureau principal de ladite compagnie \u2022lans la province sera établi à 2360 chemin Lucerne, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de mars 1962.Le Sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douville.60744 18-62\u20141117/58 The Empire Loan Company Avis est donné que « The Empire Loan Company », une compagnie à fonds social étrangère \"instituée en corporation en vertu des Lois de lu province de Manitoba, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 279.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre file, est M.Donald N.Byers, ch., de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans province sera établi à chambre 1900, 507, Companies Licensed to do Business Great Lakes Investment Co.Limited Notice is hereby given that \"Great bakes Investment Co.Limited\", a corporal ion incorporated under the Companies Act of the Province of Ontario, has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Ixian and Investment Societies Act, R.S.Q.1941, chapter 288.The principal office of the said company in the province is to be established at 901, Victoria Square, in the city and judicial district of Montreal.Its chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against it is Mr.Donald James Johnston, advocate, of the said city of Montreal.Montreal, P.Q., this 7th day of March, 1962.Donald James Johnston, 60652-10-4-o Chief Agent.Union Finance Company Limited Notice is hereby given that a licence has been granted under date of February 14, 1962 to \"Union Finance Company Limited*', pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act authorizing the said \"company to carry on business in the Province of Quebec.Dated at Montreal, P.Q.this 8th day of March, 1962.M.G.Anoch, 60713-1 l-4-o Chief Agent.Allstate Enterprises, Inc.Notice is hereby given that \"Allstate Knterprises, Inc.\", an extra-provincial company incorporated in virtue of the laws of the State of Delaware, U.S.A., has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 279.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.L.G.Hosier, of 2360 Lucerne Road, Mount Royal.The principal office of the said company in the Province is to be established at 2360 Lucerne Road, Mount Royal, in the judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, , this 15th day of March, 1962.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744-o 18-62\u20141117/58 The Empire Loan Company Notice is hereby given that \"The Empire Loan Company\", an extra-provincial company incorporated under the laws of the Province of Manitoba, has been licensed to carry ou business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Coniftanies Act, Reviser! Statutes of Quebec, 1941, chapter 279.The chief agent for the-purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.Donald N.Byers, q.c, of Montreal.The principal office of the said company in the Province is to be est a I dished at Room 1900.507, 1060 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No It Place d'Armes, en la cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15è jour de mars 1062.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.60744 4-62 - 1117/47 Guardian Hospital Equipment Co., Inc.Avis est donné (pie la compagnie « Guardiuu Hospital Equipment ('o.Inc.», une compagnie à fonds social étrangère, constituée en corporation en vertu des lois du Commonwealth de Massachusetts, E.U.A., a été uutorisée ù exercer son commerce dans lu province de Quélicc, conformément uux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, Statuts Refondus de Québec, 1941, chapitre 279.Son agent principal, aux 6ns de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre ladite compagnie, est M.VV.H.La id ley, chambre 300-455 ouest, rue Craig, en la cité de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à chambre 300-455 ouest, rue Craig, en ladite cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20c jour de mars 1962.te Sorte-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60744 9-62\u2014 1117/84 Place d'Armes, in the city and in the judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of March, 1962.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Product.60744-O 4-62\u20141117 17 Guardian Hospital Equipment Co., Inc.Notice is hereby given that \"Guardian Hospital Equipment Co., Inc.\".an extra-provincial company incorporated in virtue of the Laws ol the Commonwealth of Massachusetts, U.S.A.has been licensed to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provision.- o| the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 279.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.W.H.Leidley of Room 300-455 Craig Street W., in the city of Montreal.The principal office of the said company in the Province is to be estai dished at Room 300-455 Craig Street, W., in the said city and in the judicial district of Montreal.Given at the office cf the Provincial Secretary, this 20th day ol March, 1962.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.60744-O 9-62 \u2014 1117/81 Helium Corporation of America Avis est donné que la compagnie « Helium Corporation of America », une compagnie à fonds social étrangère, .constituée en corporation en vertu des lois de l'Etat de Delaware, E.U.A., a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies à fonds social étrangères, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 279.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre ladite compagnie est M.J.Austin Murphy, ch., de la cité de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi aux bureaux dudit M.J.Austin Murphy, en., Édifice Transportation, 132 ouest, rue St-Jacques, en ladite cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.60744-o 14-62\u20141117/91 Newrich Explorations Limited Avis est donné que la compagnie « Newrich Explorations Limited » a été autorisée à vendre ou autrement aliéner dans la province de Québec ses actions, valeurs, certificats-actions, obligations et autres titres.Son agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures exercées contre ladite compagnie, est M.J.Austin Murphy, c.r., en la cité de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province sera établi à chambre 725, 132 ouest, rue St-Jacqucs, en ladite cité et dans le district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de mars 1962.te Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.60744 1-62\u20141117/92 Helium Corporation of America Notice is hcicby given that \"Helium Corpo ration of America\", an extra-provincial company incorporated in virtue of the Laws cf the State of Delaware, U.S.A., hrs been licerscd to carry on business in the Province of Quebec, pursuant lo the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 279.The chief agent for the purpose of receiving services in prr.ositions de la Loi des compagnies de Québec, « L.C.Pharo Co.Ltd.», «I.une avis par les présentes, qu'ellç fera appli-« al ion à l'honorable secrétaire de la province de Québec jH>ur qu'il accepte I'ubandon de sa charte et en ordonne l'annulation, et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Thetford Mines, P.Q., le 8 mars 1902.Le Président, 607784 M.C.Pu a ko.L'Acier Blondeait Ltée Notice is hereby given that \"L'Acier Blondeau Ltée\", will apply to the Attorney Genera! for leave to surrender its charter.Levis, this 15th day of March, 1962.Liu; a it HloNOKAU, 60772-O President.L.C.Pharo Co.Ltd.Under the provisions of the Quebec Companies Act, \"L.C.Pharo Co.Ltd.\", hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Secretary of the Province of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation, and fix a date upon from which it shall be dissolved.Thetford Mines, P.Q., March 8, 1962.M.C.I'll AltO, 60773-O President.Compagnies dissoutes Ajax Investments Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québic, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 270, article 20, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite Ici, il a plu au secrétaire \u2022le la province d'accepter l'abandcn de la charte de la compagnie « Ajax Investments Limited », constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de (Québec par lettres patentes en date du 19 février 1951.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 mars 1962, ladite compagnie a été dissoute.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 16 mars 1962.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.607444 2664-51 René Bélanger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première padie de la Loi des compagnies de Québec, Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 276, article 26, et sujet à la responsabilité décrétée par l'article 27 de ladite loi, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de la compagnie c René Bélanger Inc.», constituée en corporation en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies de Québec par lettres patentes en date du 15 septembre 1960.Avis est de plus donné qu'à compter du 15 murs 1962, ladite compagnie a été dissoute.Donné au bureau'du secrétaire de la province, « 16 mars 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.oord of directors of the company be and it is hereby decreased from five to three.2.That the by-laws of the company be and they are hereby amended to accord with the foregoing.\" Certified true copy of by-law passed unanimously at a meeting of directors held January 30, 1962, and approved uannimously by the holders of all the shares of the company at a shareholders meeting held January 30, 1902.(Seal) Ann Rich.Presides.David Rich.60795-o Sccretar'j.5754-49 Société de Placements Ltée Règlement spécial « B » un règlement pour augmenter le nombre des directeurs.« Qu'il soit décrété et il est décrété comme un règlement de « Société de Placements Ltée » (ci-après nommée la «compagnie ») ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est augmenté de trois à cinq.2° Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du conseil d'administration.3° Tous les règlements, antérieurs de la compagnie incompatibles à icelui, sont par les présentes, amendés, de manière à donner effet à ce règlement.» Société de Placements Ltée Special by-law \"B\" a by-law to increase the number of directors.\"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Société de Placements Ltée\" (hereinafter called \"the company\") as follows: 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to five.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of 63-9-4-o Me Jean Allaikk.Cité d'Outremont Avis public est par les présentes donné que la « ( lté d'Outremont », s'adressera à la Législature do la province de Québec, à sa présente session, pour obtenir l'adoption d'une loi, aux fins d'amender, pour la cité, certains articles de la Loi dos cités et villes et de la Loi des Relations ouvrières de Québec, le pouvoir d'établir une carie d'identité à l'occasion d'un vote dans la municipalité, d'aviser tout contribuable de tout changement apporté au rôle d'évaluation, de chancer la date d'expiration des conventions collectives et d'autoriser le Conseil à réduire le taux de la taxe générale annuelle.Outremont, le 6 mars 1962.L'Avocat de la pétitionnaire, Q0637-104-O Louis-Philippe Gaonon.and curbs according to an average front line; to change the name from Town to City; to permit the regulating and the making of an identity card for voting purposes only; to change the voting day from the first judicial Monday of November to the first judicial Saturday of November, and to have only one general election for the councillors and the mayor; the evaluation of properties for the right to vote increased to $1,000.00 in value on the role or $100.00 annually in assessments for non-residents only.Montreal, December 12, 1061.Me Jean Allaikk, 60503-9-4 A ttonusy for the Town.City of Outremont Public notice is hereby given that the \"City of Outremont\", will apply to the Legislature of the Province of Quebec, at its present session, for the passing of an act to amend, for the city, certain articles of the Cities and Towns Act and of the Quebec Labour Relations Act, to wit: the power to establish an identity card at the occasion of a vote in the municipality, to notify any ratepayer of any change in the assessment roll, to change the date of expiration of the collective conventions and to authorize the council to reduce the rate of the annual general tax.Outremont, March 5, 1962.Louis-Philippe Gaonon, 60637-10-4 Attorney for the Petitioner.Liquidation \u2014 Avis dc Winding up Notices Caisse Populaire de St-Clément Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des sociétaires de la « Caisse Populaire de St-Clément », tenue à Bishopton, le 9 janvier 1962, il a été résolu que les affaires de ladite société soient liquidées volontairement, et que celle-ci soit dissoute, le tout conformément aux dispositions de la Loi des syndicats coopératifs de Québec (S.R.Q.1941, chapitre 290) et de la Loi de la liquidation volontaire des compagnies à fonds social (Ibid, chapitre 278), et que M.Patrick Larkin, inspecteur de l'Union Régionale des Caisses Populaires Desjardins de Serbrooke, a été nommé liquidateur.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce S mars 1962.Le Souesecrétaire de la province, Raymond Douville.60774-© 951-43 Caisse Populaire de St-Clément Notice is hereby given that a special general meeting of the shareholders of the \"Caisse Populaire de St-Clément\", held in Bishopton, on January 9, 1962, a resolution was adopted to the effet that the affairs of the said association be would up voluntarily, and that it be dissolved, in accordance with the provisions of the Quebec Cooperative Syndicates' Act (R.S.Q., 1941, chapter 290) and the Winding-up Act (Ibid.chapter 278), and for such purposes that Mr.Patrick Larkin, inspector of Union Régionale des Caisses Populaires Desjardins de Sherbrooke, has been appointed liquidator.Given at the office of the Provincial Secretary on March 8, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.60774 951-43 Ministère de l'Agriculture Coopérative Agricole du Comté d'Yamaska Erratum Dans l'avis concernant la Coopérative précitée, publié dans la Gazette officielle de Québec du 17 mars 1962, veuillez apporter la correction suivante: dans le texte français, à la 3e ligne, après les mots « le nom de cette » ajouter les mots « coopérative agricole est changée en celui de ».60742-x-o Department of Agriculture Coopérative Agricole du Comté d'Yamaska Erratum In the notice concerning the aforementioned Cooperative, published in the Quebec Official Gazette on March 17, 1962, kindly make the following correction: in the French text, on the 3rd line, after the words \"le nom de cette\" add the words \"coopérative agricole est changée en celui de\".60742-x-o 1678 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 man 1962, Tome 94, No 12 Ministère de l'Agriculture Industrie laitière Ordonnance No 36-62 Région de (îranby Extrait de» procès-verbaux des séances de la Commission dc l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du mardi, 13 mars 1962, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal à 10 heures du matin.Présidents: MM.Nolasque April, président, Joseph Hébert, Paul-Abel Ares, Cyril-E.Dahms, Paul Charette, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, et Charles-A.Gamache.C.R., conseiller juridique.Attendu qub, lu Commission de l'Industrie Laitière doit fixer le prix du lait, en tenant compte de la valeur du produit, des conditions de sa production, de sa manipulation, de sa livraison et des conditions «les divers marchés locaux, «le façon à sauvegarder les intérêts des producteurs-fournisseurs, «les marchands «le lait, «les distributeurs «le produits laitiers et «les consommateurs; La Commission DÉCRÈTE ce qui suit: 1° La présente ordonnance s'applique à toute personne qui, «lirectement ou indirectement, vend ou livre du lait dans les limites de la région de (îranby.2° La région «le (îranby comprend la cité de Granby, les villages de Rougemont, St-Césaire et Ste-Pudentienne, les paroisses «le St-Césaire, St-Paul-«l'Abbotsford et Ste-Pu«lentienne, ainsi que le canton de Ste-Cécile-«le-Milton.(Ste-Pudentienne est aussi connue sous le nom de Roxton Pond.) 3° Les marchands «le lait, les sociétés coopératives et les syndicats coopératifs doivent payer à leurs producteurs-fournisseurs, pour chaque 100 livres de lait qu'ils reçoivent «le ceux-ci, $4.69 net, F.A.B.la place d'affaire dudit marchand, et à même cette somme payer à la Commission de l'Industrie Laitière de la province dc Québec, un demi-cent par 100 livres de lait ainsi reçu.Le paiement du lait aux producteurs-fournisseurs se fera sur une base de 3.4% de matière grasse: a) Plus une prime de six cents par 100 livres de lait, pour chaque dixième de 1% au-dessus «le ce pourcentage; 6) Moins un rabais de six cents par 100 livres de lait, pour chaque dixième de 1% au-dessous de ce pourcentage.4° Toutefois il est loisible au marchand de lait de convenir avec ses producteurs-fournisseurs, par contrat écrit approuvé par la Commission, d'un prix mi.imum pour le lait utilisé à d'autres fins que la consommation en nature.Ce marchand de lait devra payer à ses producteurs-fournisseurs, au prix fixé par l'article 3 de la présente ordonnance, le lait utilisé pour fins de consommation en nature plus une quantité équivalant à au moins 2% du lait ainsi utilisé, et au prix déterminé dans le contrat dûment approve par la Commission, le reste du lait reçu.Tel marchand de lait devra faire parvenir à la Commission de l'Industrie Laitière, le ou avant le 15 de chaque mois, un rapport en la forme établie par la Commission, indiquant pour le mois précédent; a) la quantité totale du lait reçu; Department of Agriculture Dairy Industry Order No.36-62 Region of Granby Excerpt from the proceedings of the meetingi of the Dairy Industry Commission «»f the Provinw of Quebec.Meeting of Tuesday, March 13, 1962, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal at 10:00 o'clock in the morning.Present: Messrs.Nolasque April, President, Joseph Hébert, Paul-Abel Ares, Cyril-E.Da Inns, Paul Charette, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, and Charles-A.(îamache, q.c, Legal A«lviser.Whereas, the Dairy Industry Commission must set the price of milk by taking into account the value of the product, the conditions under which it is produced, its handling, its delivery and the conditions of the various local markets, in owler to protect the interest of the producers, suppliers, the milk dealers, the distributors of dairy products and the consumers; It is enacted as follows: 1.The present Order is applied to any person who, directly of indirectly, sells or delivers milk within the limits of the region of Granby.2.The region of Granby includes the city of Granby, the \\illages of Rougemont.St-Césaire and Stc-Pudentienne, the parishes of St-Césaire, St-Paul of Abbotsford and Sle-Pudentienne, and also the township of Ste-Cécile de Milton.(Ste-Pudentienne is also known as Roxton Pond).3.Milk dealers, cooperative societies and co-operative syndicates, must pay to their producers suppliers, for each hundred pounds of milk they receive from them, $4.69 net, F.o.B.business place of said dealer, and out of this sum pay the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec, one-half cent for each hundred pounds of milk received.The payment of milk to the producers suppliers \"shall be made on a basis of 3.4% buttcrfat : a) A premium of six cents per hundred pounds of milk shall be added for each 1/10 of 1% over this percentage; b) A deduction of six cents per hundred pounds of milk shall be made for each 1/10 of 1% below this percentage.4.Yet, the milk dealer may agree with his producers-suppliers, by written contract approved by the Commission, as to a minimum price for milk used for other purposes than fluid milk consumption.This milk dealer shall pay to his producers-suppliers, at the price fixed in article 3 of the present Order, the milk used for consumption in its natural state plus a quantity equal to at least 2% of the milk thus used, and at the price established by contract duly approved by the Commission, the balance of the milk received.This milk dealer shall supply the Dairy Industry Commission on or prior to the 15th of each month, with a report in the form as près* cribed by the said Commission, showing for the preceding month; a) total quantity of milk received; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1679 b) lu quantité «lu lait utilisé pour fins «le roi i - .Minuit ion en nature; e) la quantité «lu lait utilisé pour autres 6ns; i) la «|uantité du lait payé au prix fixé par l'article 3; e) le prix payé pour le lait utilisé à d'autres fins «ne la consommation en nature.5 Sauf les dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance, nul ne peut, dans les limites do ladite région de Granby offrir, vendre ou livrer «lu lait à des prix inférieurs à 12 cents lu ( ii pine et 20 cents la pinte.i.Nul ne peut offrir, vendre ou livrer du luit à une épicerie, à un restaurant, à un hôtel, à une cantine militaire, à «les prix inférieurs à 0> £ cent- le «lemiard, 11 cents la chopine, 19 cents la pinte et en bidon 75 cents b gall ni.7e Nul ne peut offrir, vei dre ou livrer du luit - n bidon aux institutions de charité et aux bôpi aux ù un prix inféiieur à «2 cents le gallon.Ces institutions auront U priviKge «l'acheter le luit en bouteille aux pri< fixés pour le commerce du gros, soit: 11 cei.ts la clupine et 19 cents la pinte.fj Nul marchand «le lait, société coopérative ou syndicat coopératif ne peut offrir, vendre ou li\\r.i du lait aux distributeurs de produits laitiers à un prix inférieur à 02 cents le gallon.(i Le prix «lu lait en bouteille pour distribute.ix écoliers est fixé à 6}-£ cents le demiard et li cents la mesure «le 8 onces.10 l.a présente ortlonnance abroge les ordonnances 35-56 du 27 octobre 1956, 35-56-A «lu 27 avril 1957, 35-56-B du 30 mai 1959, 35 56 (' «lu 13 août 1900 ainsi que 35-56-D du 23 décembre 1961, et entrera en vigueur le premier jour d'avril 19 2.Signé: Nolasque April, président, Joseph Hébert, commissaire, Paul-Abkl Ares, commissaire, Cyril-E.Dahms, commissaire, Paul Charette, commissaire, ( crtifu: Alphonse Savoie, secrétaire.607vs «) ' b) quantity of milk used for consumption in its natural state; c) quantity of milk used for other purposes; d) quantity of milk paid for at the price mentioned by section 3; e) price paid for milk used for other purposes than fluid milk consumption.5.Save the provisions of article 6 of the present Order, no person shall, within the limits of said region of (îranby offer, sell or deliver milk at prices inferior to 12 cents a pint and 20 cents a quart.0.No person shall offer, sell or deliver milk to a grocery, a restaurant, a hotel, a military canteen, at price inferior to 6^ cents a half- Kint, 11 cents a pint, 19 cents a quart and in tilk 75 cents a gallon.7.No person shall offer, sell or deliver milk in bulk to charitable institutions or to hospitals at a price inferior to 72 cents a gallon.Those institutions will have the privilege of buying bottled milk at wholesale prices, that is 11 cents a pint and 19 cents a quurt.8.No milk dealer, cooperative society or cooperative syndic to shall offer, sell or deliver milk to distributors of dairy products at a price inferior to 62 cents a gallon.9.The price of bottled milk delivered to pupils is fixed at ti1 cents a half-pint and 6 cents the 8 ounce container.10.The present Order repeals Orders 35-56 of October 27, 1956, 35-50-A of April 27, 1957, 35-56-B of May 30, 1959, 35-56-C of August 13, 1960 and also 35-56-D of December 23, 1961, and shall come into force on the first day of April, 1962.Signed: Nolasque April, President, Joseph Hébert, Commissioner, Paul-Abel Ares, Commissioner, Cyril-E.Dahms, Commissioner, Paul Charette, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.60788-o Ministère des Finances Assurances Department of Finance Insurance Mutual Benefit Health and Accident Association A ris de changement de nom Avis est donné, par les présentes, que « Mutual Benefit Health ana Accident Association », constituée en corporation conformément aux lois de l'Etat du Nebraska et enregistrée dans la province sous le numéro 415, a changé son nom en celui de « Mutual of Omaha Insurance Company », à compter du 6 mars 1902.Donné au bureau du Service des assurances; Ministère «les finances, le 14 mars 1962.Pour le Ministre des finances de la province, l.e Surintendant des assurances, 60775-o Gustave-E.Tremulay, ca.Mutual Benefit Health and Accident Association Notice of change of name Notice is hereby given that \"Mutual Benefit Health and Accident Association\", incorporated under the laws of the Statue of Nebraska and registered in this Province under number 415, has changed its name to \"Mutual of Omaha Insurance Company\", as from the 6th of March 1962.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Finance, the 14th of March 1962.For the Minister of Finance of the Province, Gustave-E.Tremblay, c.a., 60775-o Superintendent of Insurance.Département de l'Instruction publique Paroisse de Bagotville Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire de la paroisse de Bagotville, dans Department of Education Pariah of Bagotville Application is made to detach from the school municipality of the pariah of Bagotville, in the 1680 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No 12 le comté de Chicoutimi, les lots 423 à 425 inclusivement; 438 à 446 inclusivement; 460 à 483 inclusivement et 488 à 581 inclusivement, tous du cadastre officiel de la paroisse de St-Alphonse, canton Bagot, pour les annexer à la municipalité scolaire du village de Bagotville, dans le même comté.Québec, le 6 mars 1962.Le Surintendant de l'Instruction publiaue, O.-J.Desaulniers.) Tout employeur assujetti au présent décret doit, le ou avant le 10 de chaque mois, indiquer séparément, sur les rapports mensuels* réguliers de liste de paie pour le mois précédent qu'il est tenu de soumettre au bureau de la Commission «unjointe de l'industrie de la robe de la Province de Québec, en plus de tous autres renseignements, le montant, pour la période de paie, des bonis de vie chère ci-haut mentionnés versés à tout salarié travaillant à la pièce de la fa«^>n et sur des formules approuvées par la Commission conjointe.c) Nonobstant toutes autres dispositions aux présentes, le salaire total ne doit pas être inférieur mix minima déterminés aux articles VIII et X du présent décret.» Per lutur Cutters:-.$0.08 Other employees.0.04 Compensation for reduction in working hours: i.From the coining into force of the present amendment until December 31, 1962, each employee subject to the provisions of the foregoing paragraph working on a time work basis, shall be paid an increase of 2.56% in addition to the hourly rate in effect for each such employee immediately prior to the date of this amendment.From January 1, 1963 ami thereafter, each such employee working on a time work basis shall be paid an increase of 4% in addition to and over and above the rate payable on December 31, 1962, to such employee.Pieces workers: ii.From the coming into force of the present amendment until December 31, 1962, all employees including apprentices, except male ami female pressors, subject to the provisions of the foregoing paragraph \"/\", working on a piece work basis, shall be paid a cost of living bonus of $0.253-2 cents per hour to be added over an«l above their actual unit rates or place work earnings.From January 1, 1963 and thereafter, all said employees shall be paid a cost of living bonus of $0.303 2 cents per hour to be added' over and above their actual unit rates or piece work earnings.iii.From the coming into force of the present amendment until December 31, 1902, all male pressors excluding assistant-pressers, subject to the.provisions of the foregoing paragraph \"/\", working on a piece work basis, shall be.pai«l a cost of living bonus t>f $0.32 !e added over ami above their actual unit rates or piese work earnings From January 1, 1963 ami thereafter, all said employees shall be paid a cost of living bonus of $0.41 cents per hour to be added over and above their actual unit rates or piece ork earnings.iv.From the coming into force of the present amendment until December 31, 1902, all female presse! s, excluding assistant-pressers, subject to the provisions of the foregoing puragraph \"/\", working on a piece work basis, shall be paid a cost of living bonus of $0.283-2 cents per hour to be added over ami above their actual unit rates or piece work earnings.From January 1, 1963 and thereafter, all said employees shall be paid a cost of living bonus of $0.343 2 cents per hour to be added over .and above their actual unit rates or piece work earnings.2.General: a) The increases herein provided, whether for time work or piece work, shall be uniformly imposeil in Zone I and Zone II.6) Each ami every employer governed by this decree shall on or before the tenth of each month, on the regular monthly payroll reports, for the preciding month, which he is obliged to forward to ami file at the offices of the Joint Commission for the Dress Industry of the Province of Quebec in addition to all other information, report separately for the pay period prescribed the payment of the aforementioned cost of living bonuses, paid to each employee governed by this decree working on a piece work basis, in the manner and on the forms approved by the Joint Commission.c) Notwithstanding anything herein contained, in no case shall the total wages paid be lower than the minimum rates specified in Articles VII ami X of this Decree.\" 1692 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No 12 * La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours il compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections en double copie, si possible, que les intéressés i>ourront désirer formuler.Le Sous-secrêtaire du Travail, (.KltAKl) TltKMBLAY.Ministère du Travail, Québec, le 24 mars 1962.60757-O The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which comes into force on the date of its publication in the Quebec Officiel Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notices in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider the objections, in duplicate, if possible, which the interested parties may wish to set forth.( i ill Alii) Tkkmiu.ay, Deputy Minister of Labour.Depart ment of Labour, Quebec, March 24, 1962.60707 «.At is d'approbation de règlements L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi de lu convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), que la constitution et les règlements généraux du Comité paritaire de l'Automobile de la région de Québec, établi en exécution du décret numéro 164 du 6 février 1962, et dont le siège social est situé dans la cité de Québec, ont été approuvés par l'arrêté en conseil numéro 387 «lu 13 mars 1962, section « A ».Le Sous-ministre du Travail, ( i l'.u a i< i) Tjuemblat.Ministère «lu Travail, Québec, le 24 mars 1962.60757-O Avis de prélèvement L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes, que le Comité paritaire de l'automobile de la région de Québec, établi en exécution du décret numéro 104 du 0 février 1962, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 387 du 13 mars 1962, section « H », le tdut, d'accord avec les dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus «le Québec 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations «les employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant la met 1k m le et le taux ci-après mentionnés: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 1er avril 1962 au 31 décembre 1962, cette cotisation' s'exerce comme ci-dessous mentionné.a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret, numéro 164, doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à ]¦> de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret (salaires fixes, pourcentages, allocations, commissions ou bonis payés).b) Les artisans régis par ledit décret numéro 164 doivent verser au comité paritaire une somme de $0.40 cents par semaine, soit l'équivalent de % de 1% du salaire moyen établi dans le décret, pour le compagnon.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 164 doivent verser au comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération (salaire fixe, pourcentages, commission, allocations ou bonis).2.Mode de perception Notice of approval of by-laws The Honourable René Hamel, Minister - f Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act, (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments!, that the constitution and general by-laws of the Automobile Parity Committee, Quebec R«>gion, formed under decree number 164 of February 6, 1962, with hca«l office in the city of Quebec, have been approved by Ordcr-iii-Council number 387 of March 13, 1962, Section \"A\".GiteaBD Thkmblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Quebec, March 24, 1962.60757-0 Notice of levy The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notices that the Automobile Parity Committee, Quebec Region, formed under decree number 164 of February 6, 1962, has been authorized by by-law approved by Order in Council number 387 of March 13, 1962, Section \"B\", in conformity with the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec.1941, chapter 163 and amendments), to collect levies from the professional employers, the artisans and the employees governed by the said rt of its financial operations to the Minister of Labour on the following dates: June 30, September 30 and December 31, 1962.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Automobile Parity Committee, Quebec Region, for the period between April 1, 1962, and December 31, 1962.Automobile Parity Committee, Quebec region Head office: 181 east, St-Joseph St., Quebec 2 Estimate of the receipts and disbursements for the period between April 1, 1962 and De-ceml>er 31, 1962.Receipts: Assessments (J-2 of 1%): Professional employers.$24,800 00 Artisans.700.00 Employees.24,800.00 Total.$50,300.00 Disbursements: Salaries: Secretary.$ 0,900.00 Office employees ( 1 man, 2 women) 6,900.00 Inspectors (3 men).11,700.00 Travelling expenses: Inspectors.1,800 00 Administration.1,800.00 Office rent.1,800.00 Legal fees.2,000.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.2,000 00 Office furniture and equipment.2,000 00 Audition of books.1,000.00 Insurance and fidelity bond.200 00 Travelling expenses of president and members.1,000.00 1694 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No 12 Jetons dc présence aux membres du comité.$ 700.00 Bureau d'examinateurs.700.00 Subvention à la Commission d'Apprentissage .8,000.00 Publicité.600.00 Dépréciation.500.00 Dépenses diverses et imprévus.700.00 Total.$50,300.00 Le Sous-ministre du Travail, ( i kh ah d Tremblay.Ministère du Travail, Québec, le 24 mars 1902.G0757-o Avis de prélèvement L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), que le Comité paritaire de l'Industrie de l'Automobile du comté de Roberval, établi en exécution du décret numéro 194-B du 19 mars 1959, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 388 du 13 mars 1962, section « D », à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret suivant la méthode et le taux ci-après décrits: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 28 mars 1962 au 28 mars 1963; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 194 (B) doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ].¦> de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret.b) Les artisans régis par ledit décret numéro 194 (B) doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à J \\> de 1% du salaire moyen fixé par le Comité à $80.00 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 194 (B) doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à ^ de 1% de leur rémunération.2.Mode de perception En vue de faciliter la perception de ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 10 du mois suivant la date d'expiration dc la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné de la cotisation de l'employeur professionnel et de celles de ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge a propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de Daver ou de donner les renseignements Attendance fees to members of the Committee.$ 700.00 Board of examiners.700 ill) Subvention to Apprenticeship Commission.\u2022.8.001 00 Publicity.600.00 Depreciation.500.00 Various and unforeseen expenses.700 00 Total.180,300 UK Gerard Tremblay.Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 24, 1962.60757m Notice of levy The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice, pursuant to the provisions of the Collective Agreement \\et (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), that the Parity Committee of the Automobile Industry of the county of Roberval, formed under decree number 194-B of March 19, 1959, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 388 of March 13, 1962, Section-\"D\", to levy assessments upon the pro-fessional employers, the artisans and the cm-ploy ces governed by the said decree, according to the following method and rate: 1.Assessments The period of levy extends from March 28, 1962 to March 28, 1963; it is laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 194 (B) shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ]-> of 1% of their payroll in respect of employees governed by the said decree.6) The artisans governed by the said decree, number 194 (B) shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to of \\% of the average wage rate fixed by the commit tee at $80.00 per week.c) The employees governed by the said decree, number 194 (B) shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to ^ of 1' ol their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the collection of these assessments, the Parity Committee shall supply the professional employers with report forms on which all particulars required by the said Parity Committee shall be given.The professional employer shall complete and sign his report, and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall submit his monthly report to the Parity Committee on or before the 10th day of the month following the date of expiration of the priod for which it is requirable; the said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The committee has the right to exact sworn reports when deemed advisable.The assessments enacted by the present by-law are payable every month by the professional employer, the artisan and the employee, without notice.Should a professional employer or an artisan roflioo fr» n,V nn tn diva ill a nwucaonr informa- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1695 donné pour remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier I )'accord avec la Loi de la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.( i-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire de l'Industrie de l'Automobile du Comté de Roberval, pour la période comprise entre le 28 mars 1962 et le 28 mars 1963.Le comité paritaire de l'Industrie de 'AlTOMOniLE du comté de Roperval Siège social: Dolbeau Etal des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le-2S mars 1962 et le 28 mars 1963.I! celtes: Cot i ations m de 1%): Employeurs professionnels.$3,100.00 Artisans.1,950.00 Salariés.3,100.00 $8.150.00 Déboursée: Salaires: Secrétaire.$3.000.00 Inspecteur.1,000.00 Lover de bureau.300 00 Fiais légaux.450.00 Papeterie, impressions, timbres, téléphone et télégrammes.775.00 Vérilication des livres.85.00 Assi i r.nées et frais de cautionnement.5.00 Fiais de déplacement du président et d( s membres et délégations.1.775.00 Jetons de présence aux membres du Comité.580.00 Publicité.100.00 Dépenses diverses et imprévus.80.00 $8,150.00 Le Sous-ministre du Travail, Gérard Tremblay.Ministère du Travail, Québec, 24 mars 1902.60757-o Avis de prélèvement L'honorable René Hamel, ministre du Travail, donne avis par les présentes que^ le Comité paritaire du commerce de la quincaillerie, district de Québec, établi en exécution du décret numéro 1090, du 7 mars 1940, et amendements, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 388 du 13 mars 1902, section « A », le tout conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 163 et amendements), à prélever des cotisations des employeurs profes-sioiniils, des artisans et des salariés assujettis' nudil décret, suivant la méthode et le taux ci-apres mentionnés; 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 16 mars 1962 au 16 mars 1963; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par le décret numéro 1090 et amendements doivent fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly financial report to the Minister of Labour on the following dates: March, 31 June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Parity Committee of the Automobile Industry of the county of Roberval for the period between March 28, 1902 and March 28, 19G3.The Parity Committee of the Automobile Industry of the county of Roberval Head office : Dolbeau Estimate of the receipts and disbursements for the period between March 28, 1962 and March 28, 1963.Receipts: Assessments {l£ of 1%): Professional employers.$3,100.00 Artisans.1,950.00 Employees.3,100.00 $8,150.00 Disbursements: Salaries : Secretary.r.$3,000.00 Inspector.1,000.00 Office rent.300.00 Legal fees____.450.00 Stationery, printing, postage, telephone and telegrams.775.00 Audition.85.00 Insurance and Fidelity bond.5.00 Travelling expenses of the chairman and members and delegations.1,775.00 Members attendance fees.580.00 Publicity.100.00 Various and unforeseen expenses.80.00 $8,150.00 » Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour,' Quebec, March 24, 1962.60757-o Notice of levy The Honourable René Hamel, Minister of Labour, hereby gives notice that, the Joint Committee of Hardware Trade, Quebec District, formed under decree number 1090, of March 7, 1940, and amendments, has been authorized by a by-law approved by Order in Council number 388 of March 13, 1902, section \"A\", pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), to \"levy assessments upon the professional employers, the artisans and the employees governed by the said decree, according to the method and rate hereinafter mentioned : 1.Assessments The period of levy extends from March 16, 1962, to March 16,1963, and is laid as follows: a) The professional employers governed bv the decree number 1090, and amendments, shall 1690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 84 mars 1962, Tome 94, No 18 verser au Comité paritaire une somme équivalente à ,' de 1% des salaires, bonis ou allocations payés ii leurs salariés assujettis audit décret.6) Les salariés régis par ledit décret numéro 1090 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à }\u2022» de 1% de leurs salaires, bonis et allocations.c) Les artisans régis par le décret numéro 1090 et amendements doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente \"à }4 de 1% du salaire établi pour le salarié le moins rémuuéré, suivant leur emploi, tel que stipulé dans le décret numéro 1090 et amendements.2.Mode de perception Les cotisations sont payables entre le 1er et le 10 de chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir à la fin de chaque semaine, à même le salaire de chacun de ses salariés, les sommes qui reviennent au Comité paritaire, à titre de prélèvements.À chaque mois, l'employeur professionnel doit fournir au Comité puritaire un rapport détaillé indiquant, sur les formules mises à sa disposition par ledit Comité paritaire, les nom, prénoms et adresse de chaque sularié à son emploi, sa qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé.Ce rapport dûment signé par l'employeur professionnel doit être accompagné des cotisations payables au Comité paritaire par ledit employeur professionnel et par ses salariés.Toutes ces sommes doivent être payées en deniers ayant cours légal dans la province de Québec.Le Comité paritaire a le droit d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.L'artisan doit payer sa cotisation au Comité paritaire avant le 10 de chaque mois.3.Rapport financier Selon les termes de la Loi dc la Convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus par le Comité paritaire du Commerce de la Quincaillerie, district dc Québec, pour la période comprise entre le 16 mars 1902 et le 16 mars 1963.Comité paritaire du Commerce de i.a Quincaillerie district de Quéfec Estimé des recettes et des déboursés probables pour la période comprise entre le 16 mars 1962 et le 16 mars 1963.Recettes: Cotisations (V2 de 1%): Employeurs professionnels.$15,445.00 Salariés.15,445.00 Intérêts.40.00 Pénalités.60.00 $30,990.00 Déboursés: Salaires: Secrétariat et administration.$12,600.00 Inspecteurs.9,000.00 pay to the Parity Committee a sum equivalent to Yi of 1% of the wages, bonuses or allocations paid to their employees governed by the said decree.b) The employees governed by the decree number 1090, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to } g of 1% of their wages, bonuses and allowances.c) The artisans governed by the decree nu m her 1090, and amendments, shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to } .of 1% of the lowest wage rate established for employees, according to their category, as stipulated in the decree number 1090, and amendments.2.Mode of collection The assessments are payable, every month, between the 1st and the 10th day of each month.The professional employer shall collect, at I he end of each week, from the wages of each one of his employees, the assessments owed to the Parity Committee.Every month, the professional employer shall forward to the Parity Committee a complete report indicating, on forms supplied by the said Parity Committee, the name in full and address of every employee in his employ, his qualification or classification, the number of regular and overtime hours worked each week; the nature of the work and the wages paid.This report, duly signed by the professional employer, shall be sent together with the assessments payable to the Parity Committee by the said professional employer and by his employees.All such sums shall be paid with money that is current in the Province.The Parity Committee has the right to exact sworn monthly reports from professional employer when deemed advisable.Artisans shall pay their assessments to the Parity Committee, before the 10th of the month.3.Financial report Under the Collective Agreement Act.the Parity Committee shall submit to the Minister of Labour a quarterly report of its financial activities, on the following dates: March 31, June 30, September 30 and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Joint Committee of Hardware Trade, Quebec, District, for the period between March 16, 1962 and March 16, 1963.Joint Committee of Hardware Trade Quebec District Estimate of the receipts and disbursements for the period between March 16, 1962 and March 16, 1963.Receipts: Assessments\"^ ot l%): Professional employers.$15,445.00 Employees.15,445.00 Interests.40.00 Penalties.60.00 $30,990.00 Disbursements: Salaries : Secretary's office and administration.$12,600.00 Inspectors./.9,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 84, 1968, Vol.94, No.18 1697 Dti'Mmses d'inspection.$ 3,000.00 Jetons de présence.1,300 00 Praia «le déplacements.3,400.00 Fuis légaux-.110.00 Praia era donné pour remplir ses obligations envers le < omit é paritaire.3.Rapport financier D'accord avec la Loi dc la convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au Ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.( 'i-annexé, un état des recettes et des détwursés prévus du Comité conjoint des Tanneries et Corroieries de la province de Québec, pour la période comprise entre le 28 mars 1902 et le 27 mars 1963 inclusivement.Comité conjoint uks Tanneries et < orroierieh de la province de québec Etat «les recettes et des «léboursés probables pour la période comprise entre le 28 mars 1962 et le 27 mars 1963.inclusivement.Recetteei Cotisations 0i de 1%): Iemployeurs professionnels.$ 5,400.00 Salariés.5,400.00 $10,800.00 Déboursés: Salaires.$ 8,400.00 I dépenses d'inspection.500.00 '\u2022\".ver et éclairage.600.00 1 m pression et papeterie.70.00 1.Assessments The period of levy extends from March 28, 1962, to March 27, 1963 inclusive; this levy is laid as follows: a) The professional employers governed by the said decree, number 330 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1% of thtir payroll for the employees governed by the said decree.b) The employees governe*! by the said de- , crée, number 330 and amendments, shall pay to the Parity Committee an amount équivalent to Yi of 1% of their remuneration.2.Mode of collection In order to facilitate the colic* tion of these assessments, the Purity Committee supplies the professional employers with report forms to be filled in as required by the Parity Committee.The professional employer shall complete and sign his report and forward it to the Parity Committee every month.The professional employer shall collect, at the end of each seek, in the name of the Committee, the assessments of his employees, by means of a deduction from their wages.The professional employer shall transmit his monthly report to the Parity Committee on or l»efore the tenth day of the month following th'e date of expiration of the period for which it is requirable.The said report shall be sent together with the assessments of the professional employer and those of his employees.The Committee may have the reports sworn to when deemed advisable.The assessments laid by the present by-law are payable every month by the professional employer and the employee, without notice from the Committee.Should a professional employer refuse to pay or to give the necessary information, five (5) days notice shall be given to him to fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial report Pursuant to the Collective Agreement Act, the Parity Committee shall submit a quarterly report of its financial operations to the Minister of Labour on the following date: March 31, June 30, September 30, and December 31.Hereto annexed is an estimate of the receipts and disbursements of the Tanners and Curriers Joint Committee for the Province of Quebec for the period between March 28,1902 and March 27, 1963, inclusive.The Tanners and Curriers Joint Committee for the Province of Quebec Estimate of the receipts and disbursements for the period comprised l>etween March 28, 1962 and March 27, 1963, inclusive.Receipts: Assessments (Yi at 1%): Professional employers.$ 5,400.00 Employees.5,400.00 $10,800.00 Disbursements: Salaries.S 8,400.00 Inspection expenses.500.00 - Rent and lighting.600.00 Printing ami stationary.70.00 1700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No 12 Poste et téléphone.S 75.00 Echange (banque).- 10.00.Jetons de présence.120.00 Frais de déplacement des membres.900.00 As s u rai i ce.25.00 Vérification des livres.100.00 $10,800.00 Le Sous-ministre du Travail, Gérard Trkmblay.Ministère du Travail, Quebec, le 24 mars 1962.60757-o Postage and telephone.$ 75.00 Bank exchange.10.00 Meeting expenses.120.00 Members' travelling expenses.900.00 Insurance.25.00 Auditing.100.00 $10,800.00 Gérard Tremblay, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, March 24, 1962.60757-o Office des Marchés Agricoles du Québec Le Plan conjoint des producteurs de bois de Lotbinière Avis d'homologations de conventions intervenues entre producteurs et acheteurs de produits agricoles commercialisés Avis est donné, par les présentes, que conformément à l'article 24 de la Loi des Marchés Agricoles du Québec (4-5 Elizabeth II, chapitre 37 et amendements), l'Office des Marchés Agricoles du Québec, lors de sa séance du 9 mars 1962, a homologué les conventions intervenues entre l'office des producteurs de bois de Lotbinière et les acheteurs suivants: Albert Vachon (convention signée le 21 février 1962); Théodule Bisson (convention signée le 2 mars 1962) ; Gatien Trempe (convention signée le 28 février 1962); St-Pierre & Savoie (convention signée le 28 février 1962) ; Henri-Paul Proulx (convention signée le 2 mars 1962); St-Lawrence Corporation Ltd (convention signée le 6 février 1962).Ces conventions ont pris effet le 9 mars 1962.Montréal, ce 9 mars 1962.Le Président, Nolasque April.Le Secrétaire adjoint et Conseiller juridique, 60797-o Gilles Prégent.Le Plan conjoint des producteurs de bois de Mégantic Avis d'homologation de conventions intervenues etUre producteurs et acheteurs de produits agricoles commercialisés Avis est donné, par les présentes, que conformément à l'article 24 de la Loi des Marchés Agricoles du Québec (4-5 Elizabeth II, chapitre 37 et amendements), l'Office des Marchés Agricoles du Québec, lors de sa séance du 9 mars 1902, a homologué les conventions intervenues entre l'office des producteurs de bois de Mégantic et les acheteurs suivants: Gatien Trempe (convention signée le 28 février 1962); Armand Lambert (convention signée le 28 février 1962); Théodule Bisson (convention signée le 2 mars 1962); Henri-Paul Proulx (convention signée le 2 mars 1962); St-Lawrence Corporation Ltd (convention signée le 6 février 1962).Ces conventions ont pris effet le 9 mars 1962.Montréal, ce 9 mars 1962.Le Président, Nolasque April.Le Secrétaire adjoint et Conseiller juridique, 60797-o Gilles Précient.Quebec Agricultural Marketing Board The Lotbinière Forest Products Producers' Plan Notice of homologation of agreements between producers and buyers of marketed agricultural products Notice is hereby given that, in conformity with article 24 of the Quebec Agricultural Marketing Act (4-5 Elizabeth II, chapter .'17 and amendments), the Quebec Agricultural Marketing Board, at a meeting held on Match 9, 1962, homologated the agreements concluded between The Lotbinière Forest Products Producers' Board and the following buyers: Albert Vachon (agreement signed on February 21, 1962); Théodule Bisson (agreement signed on March 2, 1962); Gatien Trempe (agreement signed on February 28, 1962); St-Pierre & Savoie (agreement signed on February 28, 1962) ; Henri-Paul Proulx (agreement signed on March 2, 1962); St.Lawrence Corporation Ltd (agreement signed on February 6, 1962).These agreements are in force since March 9.1962.Montreal, March 9, 1962.Nolasque April, President.Gilles Préoent, Assistant Secretary 60797-o and Legal Advisor.The Megantic Forest Products Producers' Plan Notice of homologation of agreements between producers and buyers of marketed agricultural products Notice is hereby given that, in conformity with article 24 of the Quebec Agricultural Marketing Act (4-5 Elizabeth H, chapter 37 and amendments), the Quebec Agricultural Marketing Board, at a meeting held on March 9, 1962, homologated the agreements concluded between The Megantic Forest Products Producers' Board and the following buyers: Gatien Trempe (agreement signed on February 28, 1962); Armand Lambert (agreement signed on February 28, 1962); Théodule Bisson (agreement signed on March 2, 1962); Henri-Paul Proulx (agreement signed on March 2, 1962); St.Lawrence Corporation Ltd (agreement signed on February 6, 1962).These agreements are in force since March 9.1962.Montreal, March 9, 1962.Nolasque April, President.Gilles Prégent, Assistant Secretary 60797-o and Legal Advisor. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1704 Li- Plan conjoint des producteurs «le bois de pulpe de Levis et Bellechasse In* d'homologation de convention» intervenues entre producteurs et acheteurs de produits agricoles commercialisés Avis est dopné, par les présentes, que conformément à l'article 24 dc la Loi des Marchés Agricoles du Québec (4-5 Elizabeth II, chapitre 37 et amendements), l'Office des Marchés Àgri-eoles f Saguenay (12 George VI, chapter 37 and 14-15 George VI, chapter 39), and the publication of the present proclamation: o) fixing for March 5, 1902 the «late of the entry into force of the revised plan and t lie book of reference for the parts above described of the township of Cap-Chat, of the township of Tourelle, of the municipality cf Saint-Maxime du-Mont-Louis and of the township of Denoue, b) showing that a certified copy of this revised plan and book of reference was of Drummondville County of Drummond Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonde\" will be received by the undersigned J.C.Jacob, secretary-treasurer, 317, Brock Street, Diunuimml-ville, county of Drummond, until 7:30 o'clock p.m.on Tuesday, April 10, 1962, for the purchase of an issue of $650,000, of bonds f«»r the school commissioners f«>r the city of Drummondville, county of Drummond, dated May 1, MH»2, and redeemable serially from May 1,1963 to May 1, 1982 inclusively, witn interest at a rate not less than 4%%, nor more than 6%.payable seni-annually on May 1 an«l November 1 of each year.The rate of interest may be the same- for the whole issue or it may vary according to maturities.Résolution «late«l July 4.1961.2nd ami last instalment of $650,000 on a total amount of $1.300.000 \u2014 construction of a secondary school for girls, etc.For adjudication purposes only, interest shall }>e calculated as from May 1, 1962.The table of redemption is as follows: Table of redemption \u2014 9660,000 - 20 year* Vear Capital May I.1963.x $76,000 May 1, 1964.x 80,000 May 1.1965.x 68.000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24.1062, Vol.04, No.12 1709 1er mai 1966.x $49,000 1er mai 1967.x 51,000 1er mai 1968.x 55,000 1er mai 1969.x 58,000 1er mai 1970.11,000 ter mai 1971.12,000 1er mai 1972.13,000 1er mai 1973.14.000 1er mai 1974.14,000 1er mai 1975.15,000 1er mai 1976.10.000 1er mai 1977.17,000 1er mai 1978.18.000 1er mai 1979.19,000 1er mai 1980 .20,000 1er mai 1981.21,000 1er mai 1982 .23,000 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'un octroi total de 1455,187.60k accordé par le gouvernement pro-viia lal et payable en sept versements dont deux de $90,593.76b un «le $74,000 et quatre «le $50,000, de 1968 à 19G9 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.On est prié «le noter que les soumissions sont demandée! pour «les obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres (pii seront faites pour «les obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque vise, payable au pair à Drummondville, comté de Drummond.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province dc Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetai îles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée «l'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 10 avril 1962, à 7.30 heures du soir, en la salle de l'école Garceau, 270, rue Lindsay, Drummondville, comté de Drummond.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Drummondville, (Comté de Drummond), ce 20 mars 1962.Le Secrétaire-trésorier, J.C.Jacob.317, rue Brock, Drummondville, (Drummond), P.Q., Téléphone : GRanit-8-2561.60798-o May 1, 1966.x $49,000 May 1.1967.x 51,000 May 1, 1968 .x 55,000 May 1.19G9./.x 58,000 May 1, 1970.11,000 May 1, 1971.12,000 May 1, 1972 .13,000 May 1, 1973 .14,000 May 1, 1974.14,000 May 1, 1975.15.000 May 1, 1976.16,000 May 1, 1977.17,000 May 1, 197S.18,000 May 1, 1979.19,000 May 1, 1980 .20,000 May 1, 1981.21.000 May 1, 1982 .23.000 The letters \"x\" indicate the yea is during which annual payments of a total amount of $455,187.50 granted by the Provincial Government and pavable in seven instalments: two of $90,593.75.one of $74,000, and four of $50,000, from 1963 to 1969 inclusively, will be received and applied to the service of the suid loan.Please note that tenders are called for bonds rnleemable according to the above table only, and that offers for short term bonds shall not be taken into consideration.The successful tenflerer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Drummondville, county of Drummond.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at tlie head office of said bank in Toronto.The said bonds will not lie redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners, to be Held on Tuesday, April 10, 1962, at 7:30 o^clock p.m., in the hail of the Garceau school, 270, Lindsay Street, Drummondville, county of Drummond.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Drummondville.(County of Drummond), March 20, 1962.J.C.Jacob, Secretary-Treasurer.317, Brock Street, Drummondville, (Drummond).P.Q., Telephone: GRanit-8-2561.60798 Cité de Hull Comté de Hull Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné H.Stevens, greffier, Hôtel de Ville, Hull, comté de Hull, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, mardi, le 10 avril 1962, pour l'achat de $1,061,000 d'obligations de la cité de Hull, comté de Hull, datées du 1er mai 1902 et remboursables par City of Hull County of Hull Public notice is hereby given that scaled tenders, endorsetl \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned R.Stevens, city clerk, City Hall, Hull, county of Hull, until 3.00 o'clock p.m.Tuesday, April 10, 1962, for the purchase of an issue of $1,061,000 of bonds for the city of Hull, county of Hull, dated May 1st, 1962, and redeemable serially from May 1, 1963 to May 1, 1982 1710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.24 mars 1062.Tome 94, No 12 séries du 1er mai 1963 au 1er mai 10S2 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, par année, payable semi-annuellcment les 1er mai et 1er novembre de chaque année.l.e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlements «l'emprunt Nos 77* \u2014 $265,000, construction d'un poste de police; 776 \u2014 $174,-500, construction d'un poste de pompiers; 777 \u2014 $413,000, travaux d'aqueduc, d'égouts et «le voirie; 788 \u2014 $40,000, système d'alarme et d'éclairage; 790 \u2014 $48,000.achat d'équipement; 792 \u2014 $38,000, pavages et trottoirs; et 793 \u2014 $82,500, construction d'un jmste «le pompiers.Pour fins d'adjudication seulement, le calcul «l'intérêt sera fait à compter du 1er mai 1962.Le tableau «l'amortissement est le suivant: Tableau d'amortissement \u2014 $1.061,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 19(53.$ 18,000 1er mai 1964.19,000 1er mai 1965 .21,000 1er mai 1966.23,000 1er mai 1967 .23,000 1er mai 1968.25,000 1er mai 1969 .26,000 1er mai 1970 .27,000 1er mai 1971.28,000 1er mai 1972.31,000 1er mai 1973.26,000 1er mai 1974.27,000 1er mai 1975.28,000 1er mai 1976 .31,000 1er mai 1977.32,000 1er mai 1978 .34,000 1er mai 1979 .35,000 1er mai 1980 .38,000 1er mai 1981.40,000 1er mai 1982 .529,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour «les obligations à courte échéance dix an,s ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront com porter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Hull, comté de Hull.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Ottawa et ù Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetahles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne compreml pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le lOavril 1902, à 3 heures de l'après-midi, en l'Hôtel de Ville, Hull, «-omté de Hull.Le conseil se réserve le droit «le n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Hull, (Comté «le Hull), ce 21 mars 1962.Le Greffier, R.Stevens.Hôtel de Ville, Hull, (Comté «le Hull), P.Q.Téléphone : PR 7-2781.60799-O inclusively, with interest at a rate not less tlian 5% nor more than 0%e per annum, paj abl semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the fame for t hew bole issue or it may vary according to maturities.Loan by-laws Nos: 775 \u2014 $265,000, construe, lion of a police-station; 776 \u2014 $174,500, const i action of a fire-station; 777 \u2014 $413,000, work on aqueduct, sewers and roads; 788 \u2014 $40.000, alarm and lighting systems; 790 \u2014 $48,000.purchase of equipment; 792 \u2014 $38,000, pavements and sidewalks; and 793 \u2014 $82,500, construction of a fire-station.For adjudication purposes only, interest g| all be calculated as from May 1, 1962.The table of redemption is as follows : Table of redemption \u2014 $1,061,000 \u2014 20 yean Year Capital May 1, 1963.$ 18,000 May 1, 1964.19,000 May 1, 1965.21,000 May 1, 1966 .23,000 May 1, 1967.23,000 May 1.1968 .25,000 May 1, 1969 .26,000 May 1, 1970 .27,000 May 1,1971.28,000 Mav 1, 1972 .31,000 Mav 1,1973 .20,000 May 1, 1974 .27,000 May 1, 1975 .28,000 Mav 1, 1976 .31,000 Mav 1, 1977 .32,000 May 1, 1978 .34,000 Mav 1,1979 .35.000 Mav 1, 1980 .38,000 May 1, 1981.40,000 May 1, 1982 .529,000 Moreover, tenders may be forwanle«l and shall be considered as ten-year short-term ami fifteen* year short-term bonds.However, tenders shall he considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal an«l accrued interest, if any.by certified cheque pavable at par at Hull, county of Hull.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank at Ottawa and at Toronto.The 'said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the tlate of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and consider ed at a meeting of the coucnil to be held on Tuesday, April 10, 1962, at 3:00 o'clock p.m., at the City Hall, Hull, county of Hull.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Hull, (County of Hull), March 21, 1962.City Hall.Hull, (County of Hull), P.Q.Telephone: PR 7-2781.R.Stevens.City Clerk- 60790 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 24, 1062, Vol.04, No.12 1711 Ville d'Orsainville Comté de Québec \\vis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné, A.l/étourneau, secrétaire-trésorier, Hôtel de villi1, 168» 1ère Avenue, Orsainville, comté de Québec, jusqu'à 8 heures p.m., mardi, le 10 avril l.i 2, pour l'achat de $147,500 d'obligations de la ville d'Orsainville, comté de Québec, datées de 1er mai 1962 et remboursables par séries du Ici niai 1963 au 1er mai 1982 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni Supérieur à 6%, payable semi-annuellement les h r mai et 1er novembre «le chaque année.Le taux «l'intérêt peut être le même pour toute l'i ruissioH ou il peut varier suivant les échéances.logements Nos: 186.$21.282.29, tel que modifié par le règlement No.193 \u2014 travaux «le drainage, voirie, chaînes de rue et pavage; 187.151 500 \u2014 travaux de druinage, dYgouts, voirie, charnel «le rue et pavage; 190.$67,717.71 \u2014 travaux «l'aqueduc, d'égouts, drainage, etc.Tour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter «lu 1er mai 1962.l.e tableau d'amortissement est le suivant: Tui Iran d'amortissement \u2014 il47.500 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1963.$ 2,500 1er mai 1964 .3,000 1er mai 1965.3,000 1er mai 1966 .3,000 1er mai 1967 .3,000 1er mai 1968 .3,000 1er mai 1969 .3.000 1er mai 1970 .3,500 1er mai 1971.4,000 1er mai 1972.4,500 1er mai 1973 .4,500 1er mai 1974 .4,500 1er mai 1975 .4,500 1er mai 1970.5,500 1er mai 1977 .6,500 1er mai 1978 .6,500 1er mai 1979.0,500 1er mai 1980 .7,000 1er mai 1981.8,000 1er mai 1982.61.500 I le plus, des soumissions pourront être envoyées et (dies seront prises en considération pour «les ol igatkma à courte échéance dix ans ou à courte éance quinze ans.Cependant,' les soumissions i>< devront comporter qu'un seul «les trois termes.I adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations.' il al et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Charleshcurg, comté «le Québec.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province «le Québec, «le la banque dont le nom est mentionné «lans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être uccompagnée «l'un chèque accepté égal n 1% «lu montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comptent! pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérée*, a une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 10 avril 1902, à 8 heuies du soir, Hôtel de ville.168, 1ère Avenue, Orsainville, comté de Québec.Town of Orsainville County of Quebec Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Temlers for bomls\" will be received by the undersigned A.Létourneau.secretary-treasurer.Town Hall, 168, 1st Avenue, Orsainville, county of Quebec, until 8:00 o'clock p.m.on Tuesday, April 10, 1962, for the purchase of an issue of $147,500 of bonds for the town of Orsainville, county of Quebec, «lated May 1, 1962, and redeemable serially from May I, 1963 to May 1, 1T82 inelusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Uy-laws Nos.1*6.$21,282.29, as amended by by-law No.193 \u2014 drainage, roadword, curb stones, and paving; 187, $58,500 \u2014 drainage, sewers, roadwork, curbstones an«l paving; 190, $67,717.71 \u2014 work on aqueduct, in sewers, drainage, etc.For adjudication purposes only, interest shall be calculâte«l as from May 1, 1902.The table of redemption is as follows: Table of redemption $147,500 \u2014 20 years Year Capital ' Mav 1, 1963.$ 2,500 Mav 1, 1964 .3,000 Mav 1, 1965 .3,000 Mav 1, 1966 .3,000 Mav 1,1967 .3,000 May 1, 1908 .3,000 Mav 1, 1969.3,000 Mav 1, 1970.3,500 May 1, 1971.4,000 May 1, 1972 .4,500 May 1, 1973 .4,500 Mav 1.1974.4,500 May 1, 1975 .4,500 May 1, 1976 .5,500 Mav 1,1977 .6,500 Mav 1, 1978 .6,500 May 1, 1979 .6,500 May 1, 1980 .7,000 Mav 1, 1981.8,000 May 1, 1982 .01,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considère»! as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made accortling to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Charlesbourg, county of Quebec.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue an«l must specify whether interest accrued on the bonds to the douze (12-25-N.O.P.134) aux plan et subdivision of original lot number twelve (12-livre ile renvoi officiels du village incorporé de 25-N.W.Pt.134) on the officiil pkn and book Côte St-Louis, ladite partie mesurant vingt-cinq of reference of the incorporated village cf Cote pieds «le largeur sur cent quatre pieds de profon- St.Louis measuring said part twenty-five feet (leur et ayant une superficie de deux mille in width by one hundred and four feet in depth six (cuts pieds carrés, et ladite partie dudit lot and having a superficial area of two thousand est bornée comme suit: En front au sud-ouest i-ix hundred Square feet, and said part of said par la rue Jeanne Mance.d'un côté au sud-est lot is bounded as follows: in front to the south-par une autre portion dudit 1 >t No 12-25-134, en west by Jeanne Mance Street, on one side to the arriére, par une ruelle (11-P.973) et dc l'autre southeast by another portion of said lot No.côté nu nord-ouest par la portion ci-après décrite 12-25-134, in rear by a lane (11-Pt.973) and da lot No 12-25-135, auxdits plan et livre de on the other side to the northwest by the here-renvoi officiels et inafter described portion of lot No.12-25-135, on same official plan and book of reference, and 6) L'extrême partie sud-est du lot numéro b) The extreme southeasterly part of lot cent trente-cinq de la subdivision du lot numéro number one hundred and thirty-five of the subdi- vingt -cinq de la subdivision du lot originaire vision of lot number twenty-five of the subdivi- DUraéro douze (12-25-S.E.P.135) auxdits plan sion of the original lot number twelve (12-25- et livre de renvoi officiels, ladite partie mesure S.E.Pt.135) on said official plan and book of vingt-cinq pieds de largeur sur cent quatre reference the said part measuring twenty-five pieds de profondeur et comprend une superficie feet in width by one hundred and four feet in de deux mille six cents pieds carrés, ladite partie depth and containing a superficial area of two étant bornée comme suit: En front au sud-ouest thousand six hundred square feet, the said part par ladite rue Jeanne Mance, en arrière par une being bounded as follows: in front to the south- ruelle (No 11-P.974), d'un côté au sud-est, par west by said Jeanne Mance Street, in rear by la portion ci-dessus décrite du lot 12-25-34 aux- a lane (No.11-Pt.974) on one side to the south- dits plan et livres de renvoi officiels et de l'autre east by the portion hereinabove described of lot côté au nord-ouest par le le lot numéro un du lot 12-25-34 on said official plan and book of refer- numéro cent trente-cinq du lot numéro vingt- ence and on the other side to the northwest by cinq dU premier plan de subdivision du lot origi- the lot number one of lot number one hundred naire désigné par le numéro douze auxdits plan and thirty-five of lot number twenty-five on et livre de renvoi officiels du village incorporé the first subdivision plan of the original lot de ( '6te St-Louis.designated by the number twelve on said official plan and book of reference for the Incorporated Village of Cote St.Louis.Avec les bâtisses dessus érigées, portant le With buildings thereon erected bearing civic numéro civique 6585 de ladite rue Jeanne Mance, No.6585 in said Jeanne Mance Street, the north- le mur nord-ouest d Moelles est mitoyen avec la west wall wheieof is mitoyen with the adjoining propriété adjacente, et sujet à la servitude de property, and subject to the servitude erf view vue sur la propriété vendue, en faveur dc la upon the property sold in favor of the adjoining propriété adjacente au nord-ouest, ladite mi- property to the northwest, said mitoyennite and toj enneté et servitude de vue fut créée et établie servitude of view was created and established en vertu de ce certain acte exécuté entre lesdits under that certain Deed executed between said veiiiimirs et Henri Martel devant L.Trudel, Vendor's auteurs and Henri Martel, before L.notaire, le seizième de septembre dix-neuf cent Trudel, notary on the sixteenth of September, cinq lia nte deux, enregistré à Montréal sous le nineteen hundred and fifty-two, registered at numéro 971363.Montreal, under the number 971363.Toutes les dimensions ci-dessus sont de mesure All the above measurements are English anglaise.Comme ladite propriété subsiste pré- measure.As the said property now subsists with sent mont, avec tous ses droits, membres et all its rights, members and appurtenances without 1714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1968, Tonus 94, No 12 appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.» L'immeuble ci-dessus désigné sera mis à l'enchère et adjugé « en bloc » au plus offrant et i lender enchérisseur, le VINGT-QUATRIEME jour d'AVRIL J062 à DIX heures et TRENTE de l'avant -midi, à la salle d'audience No 31 au Palais de justice de Montréal ou à toute autre salle, tel que requis par les circonstances, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier «les charges déposé un greffe «lu Protonotaire «le la Cour Supérieure, et toute opposition afin d'annuler, afin de charge ou afin «le distraire à ladite licitation devra être dépotée au greffe du l'rotouotairc de ladite Cour au nnunsdouze (12) jours avant le jour 6xé comme susdit pour la vente et adjudication et toute opposition afin «le conserver devra être déposée «lans les six (6) jours après l'adjudication; et ù défaut par les parties «le déposer lesdites oppositions dans les déluis prescrits par les présent es, elles seront forcloses «lu droit «le le faire.Un dépôt de cinq mille dollars ($5,000) scru exigé avant la vente «le tout offrant ou enchérisseur.Montréal, ce 13e jour «le mars 1062.Les Procureurs de* demandeur*, 60780-12-2 Hau'kuin k Momie.exception or reserve of any kind on the part of the Vendor.\" The above designated immoveable will he auctioned and allocated \"en bloc\" to the hi \\uM an«l last bidder, on the TWENTY-KOI RTH day of APRIL, 1062 at TEN-THIRTY in the forenoon in Room No.31, in the Montreal « ourt House or in any other room as required, under the circumstances, subject to the charges, .timi, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.With reserve of perpetual right-of-way a foot and by carriage, for all property-owners and their representatives of the lobs situated in rear of the said lot six-sixtvrthree (6-63), on a strip of land feet (10') in width and one hundred rleet (100*) feet in depth which leads to Nap eon Street to the pirt in rear of the said land this strip of land being more particularly design led as follows: a strip of land taken from lot Dumber six-sixty-three (6 63), in the first range Ei of the township of Tremblay, on the official ca-dastof of the village of Ste-Anne dc Chicou* timi, measuring ten feet (10') in width bj one hundred feet (100') in depth and hounded as follows: in front by Napoleon Street, on the north, by lot number six-sixty-two (6-62).«une street and township, and on the south by the residue of lot number six-sixty-three (6-63), and finally on the west, by the undivided part of lot number twenty-seven (27).\" To be sold at tha parochial church door of St-Luc at Chicoutimi-North, on the FIFTH day of the month of APRIL, 1962, at Til H EE o'clock in the afternoon.Rene Delisle.Sheriff's Office, Sheriff.Chicoutimi, February 23, 1962.00549-9-2 Fieri Facias District de Chicoutimi Cour Supérieure, (QOCIÊTÊ CENTRALE No 31,173.{O D'HYPOTHÈQUES ET *DE LOGEMENT, corporation légalement constituée ayant son siège social à Ottawa, province d'Ontario et une place d'affaires en les cité et district de Chicoutimi, P.Q., demanderesse; vs PAUL-YVON GAGNON, 101, Constantin, Chicoutimi-Nord, district de Chicoutimi, défendeur.t Deux terrains ou emplacements connus et désignés comme étant les subdivisions cent quatre-vingt-dix-sept et deux cent cinquante et un des lois originaires quarante et un et quarante-quatre (41-197) et (44-251) dans le premier rang ouest, canton de Tremblay, au cadastre officiel du villate de Ste-Anne, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, lesdita terrain contenant une superficie de six mille deux cent quatre-vingt-dix pieds carrés (6,29f/).» Pour être vendus « en bloc » à la porte de l'église paroissiale Ste-Anne, dans la cité de Chicoutimi-Nord, le VINGT-SIXIÈME jour du mois d'AVRIL 1962, à TROIS heures de l'après-midi.le Shérif, Bureau du Shérif, René Delisle.Chicoutimi, le 15 mars 1962.60784-12-2-o Fieri Fadas District of Chicoutimi Superior Court, (CENTRAL MORTGAGE No.31,173.{ AND HOUSING COR-IpORATION, body legally incorporated, having its head office in Ottawa, province of Ontario, and a place of business in the city and district of Chicoutimi, P.Q., plaintiff, vs PAUL-YVON GAGNON, 101, Constantin, Chicoutimi-North, district of Chicoutimi, defendant.\"Two lots of land or emplacements known and designated as being the subdivisions one hindred and ninety-seven and two hundred and fifty -one of original lots number forty-one and fort; four (41-197) and (44-251) on the first range vest, township of Tremblay, in the official cadaster of the village of Ste-Anne, with the buildings thereon constructed, circumstances and dt pendencies, the said lots of land having an an a of six thousand two hundred and ninety s< uue feet (6,290').\" To be sold \"en bloc\" at the parochial church door of Ste-Anne, in the city of Chicou! inri-North, on the TWENTY-SIXTH day of the month of APRIL, 1962, at THREE o'clock in the afternoon.René Delisi ¦ Sheriff's Office, Shenff.Chicoutimi, March 15, 1962.60781 12-2 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24.1962, Vol.94, A'o.lg 1717 G ASPÊ G ASPÊ Fieri Facias de Bonù et de Terris Cour Supérieure, l A COUTURIER & FILS No 26,109.\\ LTÉE, corporation Payant son siège social à l'endroit appelé Marsoui district de Gaspé, demandeur, »* BERTRAND VALLÉE, de l'endroit a|M>< lé St-Joachim de Tourelle, district de Gaspé, défendeur.la propriété ù vendre est la suivante: « La maison avec ses circonstances et dépen-ihuices construites sur un lot faisant partie du lot mo quinze B (15-B) au cadastre officiel du premier rang, canton Tourelle, dans la paroisse de St .Joachim, étant un terrain de 65 pieds de large par 65 pieds de profondeur, borné au nord par le sommet d'une côte, vers l'est par Odilon Vallée, au sud au chemin et à l'ouest à Luc Vallée.« Les droits de propriété du défendeur sur ledit immeuble et ce qui y est actuellement construit consistent en la propriété d'une maison à l'exclusion des fondations qui sont la propriété de sa femme et du terrain qui est également la propriété de sa femme, le défendeur étant cependant propriétaire de la maison elle-même à la seul- exclusion des fondations.» Pour être vendu à la porte dc l'église paroissiale de Saint-Joachim de Tourelle, comté et district de < Iaspé, le DEUXIÈME jour d'AVRIL, mil neul cent soixante-deux à DIX heures de l'a van t- Bureau du Shérif, Percé, le 23 février 1962.U Shérif, Percy Biaro.60551 -9-2-0 Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court, i A COUTURIER & FILS No.26,109.< -C\\.LTÉE, a corporation - having its head office at a place called Marsoui, district of (iaspé, plaintiff, M BERTRAND VALLÉE, at a place called Saint-Joachim de Tourelle, district of Gaspé.defendant.The property for sale is the following: \"The house with its circumstances and dependencies built on a lot forming part of lot No: fifteen B (15-B) of the official cadaster of the First Range, township of Tourelle, in the parish of Saint-Joachim, being a lot of land 65 feet in width by 65 feet in depth, hounded on the north by the summit of a hill, on the east, by Odilon Vallée, on the south, by the road and on the west, by Luc Vallée.\"Property rights of the defendant on the said immovealbe and that which is presently built thereon consists of a house, excluding the foundation, which is the property of his wife and the lot of land which is also the property of his wife, the defendant being the owner however of the house itself, excluding only the foundation.\" To l>e sold at the parochial church door of Saint-Joachim de Tourelle, countv ami district of Gaspé, on the SECOND day of APRIL, one thousand nine hundred and sixty-two at TEN o'clock in the forenoon.Percy Biard, Sheriff's Office, Sheriff.Percé, February 23, 1962.60551 -9-2-© HULL HULL Canada \u2014 Province de Québec-District de Hull Com Supérieure, f Yi/ESTERN QUEBEC No 796.\\ W CONSTRUCTION I LTD., corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires dan- les cité et district de Hull, demanderesse, w AYLMER PARK DEVELOPMENT CORP., corps politique et incorporé, ayant sa principale place d'affaires à Hull Sud.district de Hull, défi mleresse.1° Une certaine partie ou parcelle de terrain, connue et désignée comme étant la portion nord de la demie ouest du lot numéro deux mille seize (N ptie O.14 2016), aux plan et livre de renvoi officiel» de la ville d'Aylmer, et mesurant huit eenl cinquante pieds de largeur sur ses lignes nord et sud sur neuf cents pieds de profondeur, sur ses lignes est et ouest (850' x 900') mesure an \u2022'.ise et plus on moins, et comprenant une sup< rficie totale de sept cent soixante-cinq mille pieds carrés (765,000 p.c.) et étant borné comme \u2022mit: à une extréminité, au nord, par les terres di.- -union de Hull; d'un côté, à l'est par une partie de la demie est dudit lot No 2016; en arrière, au *ud par la portion restante de la demie ouest du même lot, appartenant au vendeur; et de l'autre côté à l'ouest par le lot No 2070 au même cadastre; tel (pie le tout est présentement, avec tous les un its, membres et dépendances y appartenant.2 Ce certain emplacement décrit comme suit : toute et seulement cette certaine parcelle de terrain et lieux situés, sis et étant dans le canton Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, (\\\\7\"ESTERN QUEBEC No.796.\\ W CONSTRUCTION 'LTD., body politic and corporate, having its head office in the city and district of Hull, plaintiff, rs AYLMER PARK DEVELOPMENT CORP., body politic and corporate, having its head office in Hull-South, district of Hull, defendant.\"1.A certain piece or parcel of land, known and designated as being the northern portion of the west half of lot number two thousand and sixteen (N.pt.W.H 2016).upon the official plan and book of reference of the town of Aylmer, measuring eight hundred and fifty feet, in width in its northern and southern lines, by nine hundred feet in depth, in its eastern and western lines (850' x 900'), English measure and more or less, and containing a total superficies of seven hundred ami sixty-five thousand square feet (765,000 sq.ft.) and being hounded as follows: at one end.to the north, by the lands of the township of Hull; on one side, to the east, by part of the east half of said lot No.2016; in rear, to the south, by the remaining portion of the west half of the same lot, belonging to the vendor; and on the other side, to the west, by lot No.2070 of the same cadaster; as the whole now is; with all rights, members and appurtenances thereunto belonging.2.That certain emplacement «léseribed as follows: All and singular that certain parcel of land and premises situate, lying and being in the 1718 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÊHEC, 24 mate 1962.Tome 94.No 12 de Hull, dans le comté de Gatineau, province dc Québec, et étant composée d'une partie du lot numéro dix-neuf (pt ie 10) du premier rang (1 rg.) dudit canton, conformément à ses plan et livre de renvoi officiels et étant plus particulièrement décrite comme suit: Commençant ù un point où une ceinture de fer a été fixée sur la limite ouest de promenade Ilelmont à une distance de dix pieds (10 pi.) mesurée vers le sud, et le long de la limite ouest de la promenade Belmont de son intersection avec la limite sud du chemin Aylnier.De là, vers le sud et suivant la limite ouest de promenade Belmont trois cent quatre-vingt-dix pieds (390 pi.).De là, vois l'ouest et parallèlement vers la limite sud du chemin Aylmer, cent quarante pieds (140').De là, vers le nord et parallèlement à la limite ouest de promenade Belmont, trois cent quatre-vingt-dix pieds (390').De là, vers l'est et parallèlement à la limite sud du chemin Aylmer, cent quarante pieds (140') au |>oint de départ.I-a limite est de la parcelle dc terrain ici décrite est distante de neuf cent vingt-neuf pieds et soixante-neuf centièmes d'un pied (929.09') mesurée vers l'ouest et parallèlement à la limite sud du chemin Aylmer à partir dc la ligne separative entre le lot dix-neuf (19) et le lot dix-huit C (18C).Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par une partie dudit lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'emprunteur pour l'élargissement du chemin Aylmer; à l'est par ladite promenade Belmont; au sud par d'autres parties dudit lot dix-neuf (pties 19) appartenant à l'emprunteur et à l'ouest par une autre partie dudit lot appartenant à « Fairway Realty Company ».Ensemble avec un magasin dessus érigé.Ensemble avec le droit dc passage sur ladite partie dudit lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'emprunteur jusqu'au moment où ladite partie a été cédée par l'emprunteur à la municipalité afin de former partie du chemin public Aylmer.Ensemble avec un droit de passage sur ladite promenade Belmont (lot 19-303), tel qu'établi par la servitude enregistrée No 48119, jusqu'au moment où ladite promenade devient une rue publique.Avec et sujet aux servitudes établies No 48231 et No 48923, par lesquelles les deux cents pieds (200') «le profondeur de ladite parcelle «le terrain sont mis de côté comme terrain de stationnement, et par lesquelles les trente pieds (30') de profondeur en arrière dudit magasin sont mis de côté comme une surface de parterre.Telle que ladite propriété existe présentement avec tous ses droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte dc la part de l'emprunteur.3° Toute et seulement cette certaine parcelle ou étendue de terrain et lieux situés, sis et étant dans le canton de Hull, comté de Gatineau, province de Québec, et étant composée d'une partie du lot dix-neuf (ptie 19) du premier rang (1 rg.) conformément à ses plan et livre de renvoi officiels, et étant plus particulièremerrt décrite comme suit: Commençant à un point où une ceinture de fer a été fixée à une distance de dix pieds (10') sud vers la limite sud du chemin Aylmer, deux cents pieds (200*) mesurée vers la limite ouest de la promenade Belmont; de là vers le sud et parallèlement à la limite ouest de la promenade Belmont trois cent quatre-vingt-dix pieds (390').De là vers l'est et parallèlement à là limite sud dudit chemin Aylmer deux cent vingt-deux pieds (222').De là, vers le nord et parallèlement à ladite limite ouest de la promenade Belmont trois cent quatre-vingt-dix pieds (390').De là, vers l'est et parallèlement à la limite sud du chemin Aylmer, deux cent vingt-deux pieds (222') au point dc départ.La limite est de la parcelle de terrain ici décrite est distante de township of Hull, in the county of Gatineau, Province of Quebec, and being composed of part of lot number nineteen (pt.19), in the first range (1st rg.) of the said township, according to the official plan and book of reference thereof and being more particularly described as follows: Commencing at a point where an iron belt has been planted on the westerly l>oundary of Belmont Drive distant ten feet (10 ft.) measured sont In lv, and along the westerly lu>undary of Belmont Drive from its intersection with the southcily boundary -of Aylmer Road.Thence, southerly and following the westerly boundary of Belmont Drive three hundred and ninety feet (39(1 ft.).Thence, westerly and parallel to the southerly boundary of Aylmer Road one hundred and forty feet (140').Thence, northerly ami parallel to the westerly boumlary of Belmont Drive three hundred and ninety feet (390').Thence, easterly and parallel to the southerly boundary of Ayhncr Road one hundred ami forty feet (140') to the point of commencement.The easterly boundary of the herein «lescribed parcel of land is distant nine hundred and twenty-nine feet and sixty-nine one hundredths of a foot (929.09') measured westerly ami parallel to the southerly boundary of Ayhncr Road from the division line between lot nineteen (19) ami lot eighteen C (18C).The said parcel of land is hounded to the north by a part of the sai«l lot nineteen (pt.19) reserved by the borrower for the widening of Aylmer Road; to the east by said Belmont Drive; to the south by other parts of said lot nineteen (pts.19) belonging to the Iwrrower and to the west by another part of said lot belonging to \"Fairway Realty Company\".Together with a store building being erected thereon.Together with a right of passage over the said part of said lot nineteen (pt.19) reserved by the borrower unti such lime as the said part has been cc«led by the borrower to the municipality to form part of the public Aylmer Road.Together with a right of passage over the said Belmont Drive (lot 19-303).as established by the servitutle registered 4SI 19, until such time as the said drive becomes a public street.With and subject to the servitudes established 48231 and 48923, whereby the front two hundred feet (200') in depth of the said parcel of land is set asi«le as a parking are, and whereby the thirty feet (30') in depth in rear of the said store building is set aside as part of an \"apron area.As the said property now subsists with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve of any kind on the pail of the borrower.3.All and singular that certain parcel or tract of land and premises, situate, lying and being in the township of Hull, county of Gatineau, Province of Quebec, and being compose\" 1 of part of lot nineteen (pt.19) in the first range (1st rg.), according to the official plan and book of reference thereof, and being more purlieu-larly described as follows: Commencing it s point where an iron belt, has been planted distant ten feet (100 south of the southerly boundary of Aylmer Road, and two hundred feet (200') measured westerly from the westerly boumlary of Belmont Drive; thence, southerly and parallel to the westerly boundary of Belmont Drive three hundred and ninety feet (390').Thence, westerly and parallel to the southerly boundary of said Aylmer Road two hundred and twenty-two feet (222').Thence, northerly and parallel to the said westerly boundary of Belmont Drive three hundred and ninety feet (3900.Thence, easterly and parallel to the southerly boundary of Aylmer Road two hundred ami twenty two feet (222') to the point of commencement.The QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Slarvh 24.tm, Vol, 94.So, 12 1719 mille cent vingt-neuf pieds et soixante-neuf centièmes d'un pied (1129.69') mesurée vers l'ouest et parallèlement à la limite sud dudit chemin Aylmer de la ligne separative entre le lot dix-huit C et le lot dix-neuf (I8C et 19).Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par une partie dudit lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'emprunteur pour l'élargissement du chemin Aylmer, à l'est par une partie dudit lot dix-neuf (ptie 19) appartenant à « Fairway Realty Company ».au sud et à l'ouest par d'autres parties du même lot appartenant à l'emprunteur.Ensemble avec le magasin étant dessus érigé.Ensemble avec un droit «le passage sur ladite partie du lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'ern-prunteur jusqu'au moment où ladite partie a été cédée par l'emprunteur ù la municipalité pour former partie du chemin public Aylmer.Avec et sujet aux servitudes pour terrain de stationne ment et comme surface de parterre, tel qu'établi par les actes enregistrés sous les numéros 48281 et 1Sî)23.ci-dessus mentionnés dans la description de la première propriété.Avec la servitude pour avoir des.tuyaux de chauffage souterrains et e -tera, dedans, sur et par-dessus la partie du lot dix-neuf (ptie 19) immédiatement à l'est et appartenant ù ladite compagnie « Fairway Realty Company », tel qu'établi par lesdits actes enregistrés sous les numéros 48231 et 48923.Telle que 1 ulite propriété existe présentement avec tous h 's droits, membres et appartenances, sans exception ou réserve «l'aucune sorte dc la part, de l'emprunteur.41 Toute et seulement cette certaine parcelle ou étendue de terrain et lieux situés, sis et étant dans le canton de Hull, comté de Gatineau, province de Québec, et étant composée d'une partie du lot dix-neuf (ptie 19) du premier rang (1 rg), conformément à ses plan et livres de renvoi officiels, et étant plus particulièrement décrite comme suit: Commençant à un point où une ceinture de fer a été fixée sur la ligne separative entre la ville d'Aylmer et le canton dc Hull-Sud à une distance de dix pieds (10') mesurée vers le mu! et le long de ladite ligne separative à partir de son intersection avec la limite sud du chemin Aylmer.De là, vers l'est et parallèlement à la limite sud du chemin Ay.'mer, cent trente-quatre pieds et trois-dixièmes d'un pied (134.3').De là, vers le sud et parallèlement à ladite ligne separative entre la ville d'Aylmer et le canton de Hull, trois cent cinquante-six pieds (356').De la, vers l'ouest et parallèlement à ladite limite sud du elicmin Aylmer, cent trente-quatre pieds et trois-dixièmes d'un pied (134.3') à ladite ligne separative entre la ville «l'Aylmer et le canton de Hull-Sud.De là, vers le nord et suivant ladite ligne separative, trois cent cinquante-six pieds (356') au point de départ.Ladite parcelle bornée au nord par la partie dudit lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'emprunteur pour l'élargissement du chemin Aylmer, à l'est et au sud par d'autres parties dudit lot dix-neuf (ptie 19) appartenant à l'emprunteur, et à l'ouest par la ville d'Aylmer.Ensemble avec la construction d'allées de quilles étant dessus érigée.Ensemble avec un droit de passage sur ladite partie du lot dix-neuf (ptie 19) réservée par l'emprunteur jusqu'au moment où ladite partie a été cédée par l'emprunteur à la municipalité pour former partie du chemin public Aylmer.Avec et sujet aux servitudes pour terrain de stationnement et surface dc parterre, établies par les actes enregistrés sous les numéros 482M1 et 48923, ci-dessus mentionnés dans la description de la première et de la deuxième Propriété.Telle que ladite propriété existe présentement avec tous ses droits, membres et Appartenances, sans exception ou réserve d'au eu - easterly boumlary of the herein described parcel of land is distant one thousand one hundred and twenty-nine feet and sixty-nine one hundredths of a foot (1129.69') measured westerly ami parallel to the southerly boundary of said Aylmer Road from the division line between lot eighteen C and lot nineteen (18C and 19).The said part-el of laud is bounded to the north ky a part of said lot nineteen (pt.19) reserved by the Ixirrower for the widening of Aylmer Road, to the east by a part of the said lot nineteen (pt.19) belonging to the \"Fairway Realty Company\", to the south and to the west, by other parts of the same lot belonging to the borrower.Together with the st«>re building being erected thereon.Tog«'ther with a right of passage over the said part of lot nineteen (pt.19) reserved by the borrower until such time as the said part has been ceded by the borrawer to the municipality to form part of the public Aylmer Road.With and subject, to the servitudes for parking area ami for \"apron\" area, as established by the deeds registered under numbers 48231 and 48923, hereinabove mentioned in the «lescription of the first property.With the servitude to have underground heating pipes, et cet «Ta, in over and upon the part of lot nineteen (pt.19) immediately east and belonging to said \"Fairway Realty Company\", as established by the sai«l «leeds registered under numbers 48231 and 48923.As the said property now subsists with all its rights, members ami appurtenances, without exception or reserve of any kind on the part of the borrower.4.All ami singular that certain parcel or tract of land and premises situate, lying and being in the township of Hull, county of Gatineau, Province of Quebec, and being composed of part of lot nineteen (pt.19) in the first range (1st rg.), according to the official plan and book of reference thereof, an«l being more particularly des-cribed as follows: Commencing at a point where an iron belt has been planted on the division line between the towrr of Aylmer and the township of South-Hull distant ten feet (10') measured southerly and along said division line from its intersection with the southerly boundary of Aylmer Road.Thence, easterly ami parallel to the southerly boundary of Aylmer Road one hundred and thirty-four feet and three-tenths of a foot (134.3').Thence, southerly and parallel to the said division line between the town of Aylmer, and the township of Hull, three hundred and fifty-six feet (350').Thence, westerly and parallel to the said southerly boundary of Aylmer-Road one hundred and thirty-four feet and three tenths of a foot (134.3') to the said division line between the town of Aylmer and the township of Hull-South.Thence, northerly and following the said division line three hundred and fifty-six feet (356') to the point of commencement.Bounded the said parcel of land to the north by the part of the said lot nineteen (pt.19) reserved by the borrower for the widening of Aylmer Road, to the east and to the south by other parts of said lot nineteen (pt.19) belonging to the borrower, and to the west by the town of Aylmer.Together with the bowling alley'building being erected thereon.Together with a right of passage over the said part of lot nineteen (pt.19) reserved by the borrower until such time as the said part has been ceded by the borrower to the municipality ot form part of the public Aylmer Road.With and subject to the servitudes for parking area and for \"apron\" area, established by the deeds registered under numbers 48231 and 48923, hereinabove mentioned under the description of the first and second properties.As the said property now subsists 1720 GAZETTE OFFICIELLE DE QVÊBEC, 24 mare 1962, Tome 94, No 12 ne sorte de la part de l'emprunteur ».Pour être vendus ù la porte de l'église St-Paul, en la ville d'Aylmer, le QUATRIÈME jour d'AVRIL, 1962, à TROIS heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, ce 20 février, 1962.Le Shérif, R.St-Pierre.60553-9-2 Canada \u2014 Province de Quél>ec District de Hull Cour Supérieure, i T P.CHKNIER CO.LI-No 1672.n «l'enregistrement de Gatineau.Avec toutes bâtisses dessus érigées, membres et appartenances, lesdites bâtisses situées sur la rue North, ville d'Aylmer, province de Q lébec.Ledit immeuble sujet à une servitude pour les lignes téléphoniques et autres en faveur de The Bell Telephone Company of Canada, conformément à un acte exécuté «levant Me Lambert Gibeault, notaire, le seizième jour de novembre 1959, et enregistré au bureau d'enregistrement, Division dc Gatineau, sous le No 50763 ».Pour être vendu à la porte «le l'église Saint-Paul, en la ville d'Aylmer, le VINGT-CINQUIÈME jour d'AVRIL 1962.à TROIS heures «le l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.St-Piebre.ce 12 mars 1962.60785-12-2 Canada \u2014 Province de Québec District de Hull Cour Supérieure, i T-TARRY M.UPPADINE, No 1604.j homme d'affuiie de la ' ville de Pembroke, province d'Ontario, demandeur, re ARTHUR CARDINAL, de la ville d'Aylmer, district «le Hull, défendeur.« La demie-Nord du lot 1401 de la ville d'Aylmer, avec bâtisses dessus érigées, correspondant au numéro civique 3 rue Tiberius.» Pour être vendu à la porte «le l'église St-Paul.en la Ville d'Aylmer, le VINGT-CINQUIÈME jour d'AVRIL 1962.à QUATRE heures de l'aj rès-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, R.St-Pierre.ce 12 mars 1962.60780-12-2-o Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Cour Supérieure, ( THOMAS GRAHAM No 555-058.-j *\u2022 MCLATJRIN, vendeur, ' des cité et district de Montréal, demandeur M HUGH GROSVENOR & GEORGE FREDERICK HATFIELD, tous with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve of any kind on the part of the borrower\".To be sold at the church door of St.Paul, in the town of Aylmer, on the FOURTH day of APRIL, 1962, at THREE o'clock in the after, noon.R.St-Pierre.Sheriff's Office, Sheriff February 20, 1962.60663-9 2-o Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, ( T P.CHENIER CO No.1672.\"j J* MITED, a body politic ' and corporate having its lu ad office and principal place of business in the \u2022 ity of Ottawa, Province of Ontario, and a place ôf business in the town of Aylmer, in the district of Hull, plaintiff, it ALVIN GOODFELLOW, of the town of Aylmer, in the district of 1! .11, defendant.\"An immoveable situated in the town of Aylmer, county of Gatineau, Province of Quebec, consisting in all that property known and designated as being lot number two hundred and twenty-four of the official subdivision cf original lot number two thousand one hundred and eighty-seven (2187-224), according to the offii ial plan and book of reference for the said town of Aylmer, registration division of Gatineau.With all buildings thereon elected, members and appurtenances, said buildings located on North Street, town of Aylmer, province of Quebec.Subject said immoveable to a servitude fur telephone lines and others in favour of The il.II Telephone Company of Canada, as per died executed before M.Lambert Gibeault, notary, on the sixteenth day of November, 1959.and registered at the registry office, Gatineau division under No.50763\".To be sold at the Saint Paul church door, in the town of Avlmer, the TWENTY-FIFTH day of APRIL.1962, at THREE o'clock in the afternoon.R.St-Piekuk.Sheriff's Office, Sken ¦ March 12, 1962.60785- ! 2 2-o Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Superior Court, ( \"LJARRY M.UPPADINE.No.1604.i businessman of I he ' town of Pembroke, Province of Ontario, plaintiff, rs ARTHUR CARDIN \\L.of the town of Aylmer, district of Hull, defendant \"The north half of lot 1401 in the (own of Aylmer, with the buildings thereon erected, corresponding to civic number 3 Tiberius Street.\" To be sold at the church door of St-Paul, in the Town of Aylmer, on the TWENTY-FP TH day of APRIL, 1962, at FOUR o'clock in the afternoon.R.St-Pieriu.Sheriff's Office.Shcr Iff March 12.1962.60786 12-2 Canada \u2014 Province of Quebec District of Montreal Superior Court, i THOMAS GRAHAM No.555-058.< * MCLAURIN, salesman.' of the city and distnY* of Montreal, plaintiff, M HUGH GROSVENOH & GEORGE FREDERICK HATFIELD, both of J QIEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1062, Vol.94.No.12 1721 deux de la cité de Londres, Angleterre, en leurs qualités de représentants légaux, syndics et exécuteurs de là succession de feu l'Honorable K ictiard De Aquila, baron S ta 1 bridge, ayant un bureau et place d'affaires en les cité et district de Montréal à 360, ouest, rue St-Jacques.Ladite - ¦¦(¦cession possédant une propriété immobilière dans b» province de Québec, défendeurs-es-qualité.« Toute cette propriété connue et désignée comme étant le lot trois « B » (3-B) du septième rang (R.7) conformément aux plan et livre de r voi officiels du canton de Templeton, et plus complètement décrit comme formant partie du lot No 3, du septième rang de la subdivision originaire de Templeton bornée vers le nord par le No 3A, vers l'est par le lot No 2B, vers le sud pir la ligne separative entre les rangs 7 et 6, vis l'ouest par le lot 4B; ayant vingt-six chaînes 11 soixante chaînons de front, sur trente-sept ébahies et trente chaînons de profondeur, formant quatre-vingt-dix-neuf acres et trente-quatre perches de superficie.Toute cette propriété connue et désignée com-me étant le lot numéro un (1) de l'enclave, conformément aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, et plus complètement décrite comme suit: \u2014 De forme irrégulière, bornée vers le nord par le canton de Portland, vers l'est par le canton de Buckingham, vers le sud par la ligne separative entre les rangs 14 et 13, vers l'ouest par le lot No 2, comprenant cent quarante-quatre acres dc superficie.Toute cette propriété connue et désignée i nime étant le lot deux (2) de l'enclave, conformément aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Templeton, et plus complètement décrite comme suit: \u2014 De forme irrégulière, bornée vers le nord par le canton de Portland, vers l'est par le lot No 1, vers le sud par le lac Il heaume et la ligne separative entre les rangs Il et 13, vers l'ouest par le lac Rhéaumc et le lot No 3; comprenant cent trente et un acres de mi perfide.» Pour être vendus à la porte de l'église St.Antoine, à Perkins, district de Hull, le DEUXIÈME jour de MAI, 1962.à TROIS heures de l'après-midi.Le Sliêrif, !'-ni-eau du Shérif, R.St-Piehke.ce 19 mars, 1962.60807-12-2 MÉGANTIC Fieri Facias de Bonis et de Terris District de Mégantic our de Magistrat, (f^ÉRARD LABREC-No 2819.\\ QUE, entrepreneur- ' électricien, domicilié à Lys-'er, district de Mégantic, demandeur, versus EDGAR GUÉRARD, de Ste-Anastasie, défendeur.« Un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot numéro neuf (ptie 9) du \u2022niastre officiel fait pour le troisième rang du canton de Nelson, lequel emplacement, situé sur partie nord-est de cedit lot, contient une demie arpent en superficie, mais de forme carrée et est situé à environ trois arpents et demi de la ligne divisant les lots huit et neuf dudit rang, \u2022'edit emplacement borné au sud-est par le chemin de la route cinq et des trois autres côtés par le résidu du lot No 9, appartenant à Alphonse Côté ou représentant, avec maison dessus construites, circonstances et dépendances.» the city of London, England, in their qualities of legal representatives, trustees and executors of the estate of the late Honourable Richard De Aquila, Baron Stalbridge, having an office and place of business in the city and district of Montreal at 360, St.James Street, West.The said estate owning real property in the province of Quebec, defendants-es qualité.\"AU that property known and designated as being lot three \"B\" (3-B) in the seventh range (R.7), according to the official plan and book of reference for the township of Templeron, and more fully described as forming part of lot No 3, in the 7th, range of the primitive subdivision of Templeton, bounded towards the north by No.3A, towards the east by lot No.2B, towards the south by the division line between ranges 7 and 6, towards the west by lot No.4B; having twenty-six chains and sixty links in front, by thirty-seven chains and thirty links in depth, forming ninety-nine acres and thirty-four perches in superficies.All that property known and designated as being lot one (1) in the Gore, according to the official plan and book of reference of the township of Templeton, and more fully described as folios:\u2014 Of irregular figure bounded toward the north by the township of Portland, towards the east by the township of Buckingham, towards the south by the division line between ranges 14 and 13, towards the west by lot No.2, containing one hundred and forty-four acres in superficies.All that property known and designated as being lot two (2) in the Gore, according to the official plan and book cf reference of the township of Templeton, and more fully described as follows:\u2014 of irregular figure, bounded towards the north by the township cf Portland, towards the east by lot No.1, towards the south by Rhéaume Lake, and the division line between ranges 14 and 13, towards the west by Rhéaume Lake and lot No.3; containing one hundred and thirty-one acres in superficies\".To be sold at the door of the church of St-Antoine, at Perkins, district of Hull, on the SECOND day of MAY, 1962, at THREE o'clock in the afternoon.R.St-Piekhe, Sheriff's Office, Sheriff.March 19, 1962.60807-12-2-o MEGANTIC Fieri Facias de Bonis et de Terris District of Mégantic Magistrate's Court, fp ERA RD LABREC-No.2819.) ^ QUE, contractor-elec-'trician, domiciled at Lys-ter, district of Mégantic, plaintiff, versus, ED-GARD GUÉRARD, of Ste-Anastasie, defendant.\"An emplacement known and designated as being a part of lot number nine (pt.9) in the official cadaster made for the third range in the township of Nelson, which emplacement, situated on the northeast part of this said lot, has an area of one-half arpent, but being square in shape, and is situated at approximately three and one-half arpents from the line dividing lots eight and nine on said range; said emplacement is bounded on the southeast by the road of Highway five, and on the three other sides by the remainder of lot No.9 belonging to Alphonse Côté or representative, with the house thereon constructed, circumstances and dependencies.\" 1722 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 24 man 1962, Tome 94, A'o 12 Pour être vendu à la |x>rte de l'église de la paroisse Ste-Anastasie de Lyster, le SIXIÈME jour du mois d'AVRIL, 19(12, à DEUX heures de l'après-midi.U Shérif, Bureau du Shérif, Loi ih Camire.Thetford Mines, le 23 février 1902.«0504-9-2-0 MONTRÉAL Fieri Facias de Bonis et de Terris Cour Supérieure \u2014 District «le Montréal Montréal, à savoir: ( pENTURY CREDIT No 542 753.< V-J UNION (LACHI-^NE) LTD., demanderesse, vs W.FRED OCKENDEN, défendeur, « Un terrain ayant front sur lu rue Provost dans la cité dc Lachine, mesurant cinquante-quatre pieds et quatre dixième de pied de large par quatre-vingt-treize pieds et cinq dixième de pied de profondeur dans la ligne ouest et quatre-vingt-quatorze pieds de profondeur dans sa ligne est, mesure anglaise plus ou moins composé des subdivisions deux cent soixante-seize et deux cent soixante-dix-sept du lot numéro sept cent neuf (709-276 et 277) aux plans et livres de renvoi officiels de la ville de Lachine, avec bâtisses y érigées.» Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, lé SIXIÈME jour du mois d'AVRIL 1962, à DIX heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, L.-P.Caisse, c.r.Montréal, le 27 février 1962.60584-9-2-o Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( t ÉO PERRAULT LTÉE, No 512 847.< *-» demanderesse, vs J.-C.I CHAMPAGNE, défendeur, i Un emplacement composé de la subdivision 563 du lot originaire No 143 (143/563) et redivision 2 de la subdivision 562 du lot originaire No 143 (143/562/2 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine de Lon-gueuil, avec l'immeuble dessus en voie de construction, portant le numéro civique 880, avenue St-Georges, en la cité de Jacques Cartier.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du cdmté de Chambly, à Longueuil, le SIXIÈME jour du mois d'AVRIL 1962, à ONZE heures du matin.Le Shérif, Bureau du Shérif, L.-P.Caisse, c.r.Montréal, le 27 février 1962.60585-9-2 QUÉBEC Fieri Facias Québec à savoir: (t A CITÉ DE SAINTE-No 114-907.1 J-» FOY, corporation léga-\" lement constituée ayant son siège et sa principale place d'affaires à Ste-Foy, 200 Route de l'Église, Ste-Foy, Que., contre GILLES BERTRAND, 2740, Bridge Water, Ste-Foy, Que.Tout le résidu non-resubdivisé du lot quatre cent dix\u2014cinquante-huit (410-58) du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Foy, comté et division d'enregistrement de Québec, mesurant To *be sold at the parochial church do.of Ste-Anastasie de Lyster, on the SIXTH day of the month of APRIL, 1962.at TWO o'clock in the afternoon.I.oris Cam lui: Sheriff's Office, Sheriff.Thetford Mines, February 23, 1962.00501 92 MONTREAL Fieri Facias de Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit : fpENTURY CREDIT No.542 753.< ^ UNION (LA( III.* NE) LTD., plaintilf.n W.FRED OCKENDEN, defendant.\"A lot of land having frontage on Provost Street in the city of Lachine, measuring fifty-four and four-tenths feet in width by ninety-three and five-tenths feet in depth on its west line and ninety-four feet in depth on its east line, English measure, more or less, composed of the subdivi-sions two hundred and seventy-six and two hundred and seventy-seven of lot number seven hundred and nine (709-276 and 277) in the official plan and book of reference of the town of Lachine, with the buildings thereon erected.\" To be sold at my office in the city of Montreal, on the SIXTH day of the month of APRIL.1962, at TEN o'clock in the forenoon.L.-P.Caisse, q.c.Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, February 27, 1962.60584-9-2 Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: (t ÊO PERRAULT LTEE, No.512 847.\\ *-* plaintiff ss J.-C.CHA M-IPAGNE, defendant.\"An emplacement composed of subdivision 563 of Original Lot No.143 (143/563) and redivision 2 of subdivision 562 of original lot No.143 (143/562/2) of the official plan and book of reference of the parish of St.Antoine de bon-gueuil with immoveable thereon in the process of erection bearing civic number 880 St.Georges Ave, in the city of Jacques Cartier.\" To be sold at the registry office of the county of Chambly, at Longueuil, the SIXTH day of the month of APRIL 1962, at ELEVEN o'clock in the forenoon.L.-P.Caisse, q.c, Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, February 27, 1962.60585-9 2-o QUEBEC Fieri Facias Quebec to wit : (t A CITÉ DE SAINTE-No.114-907.FOY, body legally in- 'corporated having its head office and chief place of business in Ste-Foy, 200 Church Road, Ste-Foy, Que., versus GILLES BERTRAND, 2740, Bridge Water, Ste-Foy, Que., All the non-resubdivided remainder of lot four hundred and ten\u2014fifty-eight (410-58) in the official cadaster of the parish of Sainte-Foy, county and registry division of Quebec, measuring eighty QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, W62.Vol.1)4, So.12 1723 quatre-vingt* (80*) pieds de largeur sur cent (100') pieds de profondeur, borné au nord-ouest par les lots 410-55-2 et 410-55-3, au nord-est par le lut 410-58-1, au sud-est par le lot 410-5 (Place Beloeil) et au sud-ouest par la partie ci-après décrite du lot 410-59.La partie non-subdivisée du lot 410-59 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Foy, mesurant dix (10') pieds de largeur sur cent (Hi' l'i pieds de profondeur, borné au nord-ouest par le lot 410-56-1 au nord-est par le résidu non resubdivisé du lot 410-58 ci-dessus décrit, au sud-est par le lot 410-5 (Place Beloeil) et au sud-ouest par le résidu dudit lot 410-59.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendus à la porte de l'église paroissiale de Sainte-Foy, comté de Québec, le SIXIÈME jour d'AVRIL prochain à DIX heures de l'avant-midi.Le Sliêrif, Bureau du Shérif.Me Antoine Bourcîet.c.r.Québec, le 27 février 1962.60586-9-2-o [Première insertion: 3 mars 1962] [Deuxième insertion: 24 mars 1962] (80') feet in width by one hundred (100') feet in depth, bounded on the north-west by lots 410-55-2 and 410-55-3, on the north-east by lot 410-58-1, on the south-east by lot 410-5 (Place Beloeil) and on the south-west by the part of lot 410-59 described below.The unsubdivided part of lot 410-59 in the official cadaster of the parish of Sainte-Foy, measuring ten (10') feet in width by one hundred (100') feet in depth, bounded on the north-west by lot 410-56-1, on the north-east by the non-resub-divided remainder of lot 410-58 described above, on the south-east by lot 410-5 (Place Beloeil) and on the south-west by the remainder of said lot 410-59.The whole with the buildings thereon constructed, circumstances and dependencies.To be soltl at the parochial church door fo Sainte-Foy, county of Quebec, on the SIXTH day of APRIL next, at TEN o'clock in the forenoon.Me Antoine Bourget, q.c, Sheriff's Office, Sheriff.Quebec, February 27, 1962.60586-9-2 » [First insertion: March 3.1962] [Second insertion: March 24, 1962] ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour Supérieure, (t 'OFFICE DU CRÉDIT No 25,882.< *-* AGRICOLE DU QUÉ-¦ BEC, corps politique et incorporé ayant son siège social ù Québec, demanderesse as CHARLES GAGNÉ, cultivateur domicilié à St-André, comté de Roberval, défendeur.Avis de vente « Les lots de terre connus et désignés sous les numéros trente-sept-A-, trente-sept-B-, trente-sept-F et trente-sept-G- (Nos 37-a, -37-b-, 37-f-, 37-g-) du premier rang du cadastre du canton Dequen.Sauf à distraire desdits lots trente-sept-A-et ( rente-sept-B-, le droit de passage du chemin de fer sur partie des lots en faveur de The Méta-het chouan Sulphite & Power Co.Ltd.lequel terrain n'est ni occupé ni clôturé, ainsi que les droits de baignage que peut avoir ladite compagnie sur partie des lots susdits.Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances ».''our être vendu en « bloc » à la porte de l'église de la paroisse de St-André, comté de Roberval, le QUATRIÈME jour d'AVRIL, 1962, à DEUX heures de l'après-midi.La voie & de la Boissiere, Pav le Shérif, Bureau du Shérif, Leo de la Boissiere.Roberval, le 24 février 1962.60565-9-2-o ! Première insertion, samedi, le 3 mars, 1962.] ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Superior Court, fPHE QUEBEC FARM No.25,882.< A CREDIT BUREAU, Ibody politic and corporate, having its head office in Quebec, plaintiff, vs CHARLES GAGNÉ, farmer, domiciled at St-André, county of Roberval, defendant.Notice of sale \"The lots of land known and designated under the numbers thirty-seven-A-, thirty-seven-B-, thirty-seven-F and thirty-seven-G- (Nos 37-a-, 37-b-, 37-f-, 37-g-) on the first range in the cadaster of the township of Dequen.Save to be withdrawn from said lots thirty-seven-A- and thirty-seven-B-, is the railroad eight-of-way on part of lots in favor of The Métabetchouan Sulphite & Power Co.Ltd., which terrain is neither occupied nor fenced in, as well as the swimming rights which said company may have on part of the above-mentioned lots.The whole with buildings thereon constructed, circumstances and dependencies\".To be sold \"en bloc\" at the parochial church door of St-André, county of Roberval, on the FOURTH day of APRIL, 1962, at TWO o'clock in the afternoon.La voie & de la Boissiere, By: Léo de la Boissiere, Sheriff's Office, Sheriff.Roberval, February 24, 1962.60565-9-2 [First insertion: Saturday, March 3, 1962.] Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval Cour de Magistrat.I TJTOLLINGER MACHI-No.34,847.\\ n NES COMPANY I LTD, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires à Montréal, district de Montréal, deman- Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quebec District of Roberval Magistrate's Court, ( \"LJOLLINGER MACHI-No.34,847.\\ H NES COMPANY ' LTD, corporation legally incorporated having its principal place of business in Montreal, district of Montreal, plaintiff vs 1724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, H mars nm, Tome 94, No 1» Cour No dcur if ROBERT GIRARD, résidant et domicilié à Ste-Elizabeth de Proulx, district de Roberval, défendeur.Avis de vente A titre de possesseur « Anima Domini s f Le lot de terre étant connu et désigné comme étant le numéro treize (13) du rang huit (8) du canton Proulx, avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.» Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Ste-Elizabeth de Proulx, dans le comté de Roberval.le CINQUIÈME jour d'AVRIL 1962 à DEUX heures de l'après-midi.La voie & oe la Boissiere, Bureau du Shérif, Par le Shérif, Palais de Justice, Léo de la Boissiere.Roberval, le 19 février 1962.60566-9-2-o [Première insertion, samedi le 3 mars 1962] SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec District de St-Hyacinthe Supérieure, j t ÉOPOLD COTÉ, gentil-?13-381.\\ homme, domicilié en les ' cité et district de St-Hyacinthe, demandeur, vs EUGÈNE LACHANTE, résident à Cap St-Ignace, en le district de Montma-gny, défendeur, et LE REG1STRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE ST-HYACINTHE, mis-en-cause.Annonce de tente par le Shérif La propriété à vendre est la suivante: « Un emplacement situé en la cité de St-Hyacinthe faisant partie du lot numéro cent quatre-vingt-douze (ptie 192) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Hyucinthe-Le-Confes-seur, mesurant cinquante pieds (50') de largeur par soixante-quinze (75') de profondeur, le tout à la mesure anglaise et plus ou moins, limité au front par le chemin appelé « Petite Route s conduisant de la voie Sir Wilfrid Laurier au chemin de front de la rivière Yamaska, à la profondeur et du côté sud-ouest par d'autres parties du dit lot appartenant à Eugène Morin ou représentants et du côté nord-est par une autre partie du même lot appartenant à Benoit Gaudreault ou représentants; avec une maison à logement unique dessus érigée.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, à St-Hyacinthe, en ledit district, le MERCREDI, VINGT-CINQUIÈME jour d'AVRIL, 1962, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Gérard Beaudet.St-Hyacinthe, le 14 mars 1962.60687-12-2-q ROBERT GIRARD, residing and domiciled at Ste-Elizabeth de Proulx, district of Roberval, defendant.Notice of sale Under deed of ownership \"Animo Domini \"Lot of land being known and designated u being number thirteen (13) of range eight (8) of the township of Proulx, with buildings thereon erected, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the church.door of the pan ; of Ste-Elizabeth de Proulx, in the county of Roberval, on the FIFTH day of APRIL, 1962 st TWO o'clock in the afternoon.La voie & de la Boissiere, Sheriff's Office, By: Leo de la Boissiere, Court House, Sheriff.Roberval, February 19, 1962.60560 9-2 [First insertion: Saturday, March 3, 1962, SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province of Quebec District of St.Hyacinthe Superior Court, f t ÉOPOLD COTÉ, gentle No.13-381.j asi.man, domiciled in the ^city and district of St.Hyacinthe, plaintiff, r* EUGÈNE LACHA Ni K.residing at Cap St-Ignace, in the district of Montmagny, defendant, and THE REGISTRAR FOR THE REGISTRY DIVISION OF ST.HYACINTHE, mis-en-cause.Announcement of sale by Sheriff The property to be sold is the following \"An emplacement situated in the city of St-Hyacinthe, forming part of lot number one hundred and ninety-two (P.192) in the official plan and book of reference for the parish of St-Hyacinthe-le-Confesseur, measuring fifty feet (50') in width by seventy-five feet (75') in depth, the whole english measure and more or b as, bounded in front by the road called \"Petite Route\", going from Sir Wilfrid Laurier Road to the road in front of the Yamaska River, in depth and on the south-west side by other parts of said lot belonging to Eugène Morin or représentât i\\ es.and on the north-east side by another part of the same lot belonging to Benoit Gaudreault or representatives; with a sole lodging house thereon erected.\" To be sold in the sheriff's office, in the Court House, in St.Hyacinthe, said district on WEDNESDAY, the TWENTY-FIFTH day of APRIL, 1962, at TEN o'clock in the forenoon.Gérard Beaudet.Sheriff's Office, Sher St.Hyacinthe, March 14, 1962.60787 2-2 INDEX IV© 12 ACTION ACTION en séparation de biens for Separation as to Property Bérubé rs Martin.'.«»52 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 308-E - Construction, Montréal (Erratum).I«53 314 - Ouverture au jalonnement de terrains soustraits au piquetage en claims miniers, dans les cantons (îarnier, Jogucs et Taillon, district electoral de Lac St-Jean; labrecque et Rouleau, district électoral de Jonquière-Kénogami; Milot et Dalmas, district électoral «le Roberval.I»'52 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 24, 1962, Vol.94, No.12 1725 ARRÊTÉS en Goneell (suite) ORDERS in Council (continued) ill Opening to staking of terrains withdrawn from pegging of mining claims in the townships of Gamier, Jogues and Taillon, electoral district of Lake St.John; Labrecque and Rouleau, electoral district of Jonquière-Kénogami; Milot and Dal mas, electoral district of Roberval.1652 3S4 - Classement du vieux cimetière protestant Saint-James, Trois-Rivières.1656 5S3 - Classification of the old Protestant cemetery of Suint James, Trois-Rivières.1656 188-E - Coiffeurs, Drummondville.1654 388-E - Hairdressers, Drummondville.1654 38843 - Barbiers, coiffeurs pour hommes et coiffeuses pour dûmes, Sherbrooke.1654 388-G - Barbers and hairdressers, Sherl>ooke.1654 ¦NS-H - Construction, Province.1655 ASSEMBLÉE < )uebec Central Rai I way Company.W IS A-iteuil, ville town (Règl.No 180 - By-law No.180) BILLS Sanctionnés - Sanctioned.MEETING NOTICES BILLS COMPAGNIES AVIS relatif m à la loi des Autorisées à taire des affaires COMPANIES Notices relative to the Act of Licensed to do Business \\llstatc Enterprises, Inc.1659 Empire Loan Company (The).1659 ' rcat Lakes Investment Co.Limited.1659 I iiiardian Hospital Equipment Co., Inc.1660 iulium Corporation of America.1660 Newrich Explorations Limited.1660 I nion Finance Company Limited.1659 Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Acier Blondeau Ltée (L*).1661 Pharo (L.C.) Co.Ltd.1661 Dissoutes Dissolved \\jax Investments Limited.1661 Mélanger (René) Inc.1661 Bright Metals Ltd.1661 Brookfield Construction Ltd.1662 Burnbrae Investments Limited.1662 ( !ul» des Moose de Montréal, 1111 Inc.(Le).1662 Entreprises Nicolet Limitée (Les).1663 Estate Holdings Limited.1663 Esteem Construction Co.Ltd.1663 'îarage O.Maurice Inc.1663 ( iatineau Curling Club (The).1664 Gold Clothing Company Limited (The).1664 Kennco Explorations (Quebec) Limited.1664 Montrose Securities Ltd.1664 N'ashwaak Corporation of Canada Limited.1665 Placements Alves Inc.(Les).1665 St Come Wood Turnings Company Limited.1665 S|>ortee Knitwear Corp.1666 (Ike's Holding Corporation Ltd.1666 Velan Valve Company Ltd.1666 111 \u2022 ors M iscellaneous Apollon Construction Co.Ltd.(Dir.).1670 Vutomobiles, Incorporated (Dir.).1670 Automobiles, Incorporée (Dir.).1670 Beaudry (O.) & Fils Limitée (Dir.).1673 Beaudry (O.) & Sons Limited (Dir.).1673 Branded Hosiery Mills Corporation (Dir.).1671 Centre Psycho-Social du Diocèse de Valleyfield (Dir.).Centre Psycho-Social du Diocèse de Valleyfield (Régi- By-laws).Chantecler Ski Tows Inc.(Dist.de l'actif - Dist.of assets).Conseil des Oeuvres du Diocèse de Ste-Anne (Le) - (Règl- By-laws)- Conseil des Oeuvres du Diocèse de Ste-Anne (Le) - (Dir.).Corporation des Entrepreneurs en Climatisation (La) - (lUgl.).Corporation of Conditioning Contractors (By-law).Desrosiers & Frère Limitée (Dir.).Family Life Education Council of Montreal (Dir.).Family Life Education Council of Montreal (Règl-By-laws).Festival International du Film de Montréal (Dir.).Festival International du Film de Montreal (Règl.).Jay Elle House Inc.(Règl.- By-law).Lakeshore General Hospital (The) - (Dir.).Lakeshore General Hospital (The) - (Règl.-By-law).Ligue des Citoyens de St-Jean, Inc.(La) -(Dir.).Ligue des Citoyens de St-Jean, Inc.(La) - (Règl.- By-law).McCord Street Sites Limited (Dir.).McCord Street Sites Limited (Dir.).Miss Brown's Dry Cleaning Inc.(Dir.).Montreal International Film Festival (Dir.).Montre»! International Film Festival (By-laws).Renauld (Gérard) Inc.(Dir.).Savanne Building Ltd.(Dist.de l'actif - Dist.of assets).Société de Placements Ltée (Dir.).Toulon Construction Inc.(Dir.).Unlimited Skills Inc.(Dir.).1656 1656 1657 1673 1673 1670 1666 1667 1668 1668 1668 1667 1671 1669 1668 1671 1674 1673 1668 1668 1671 1672 1672 1669 1668 1669 1667 1672 1667 Lettres patentes Letters Patent Alcalum Products Limited.1602 Amicale des Sommeliers de la Province de Québec.\u2022 1603 Armural Inc.1003 Association des Terrains de Camping du Québec.1603 1720 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, g* mars 196$.Tome !)4, S'a 12 Lettres patente» Letters Patent (suite) (continued) Associât ion Diocésaine «les Commissions Scolaires du Diocèse de Sherbrooke Inc.(L').1604 Auberge de Sutton Limitée.1604 Audet & Bergeron Ltée.1605 Beausoleil (C.) Inc.1605 Bel Automobiles (1001 ) I\"c.1605 Billmar Investments Ltd.1006 Boulais & Frère Inc.1606 Boulangerie Lina Inc.1606 Boulevard Asphalt Paving Ltd.1607 Charette (Levis) Inc.1607 Chevaliers et Chevalières de Croteau Inc.1607 Chinese Rest amant Dragona Inc.1026 Club de Hockey Rosemont Junior Inc.1608 Cobea Enterprises Inc.1011 Collier d'Or Inc.(Le).1608 Comité di Loisirs St-Charles île Drummond Inc.1608 Corona Hosiery Mills Ltd.1600 Côté (Aimé) Ready-Mix Ltée.1609 Créma/.ic Lounge Inc.1610 Dominion Marking Devices Ltd.1010 Dorion Welding Inc.1632 Entrepôts Frigorifiques Mélro|M>lc Ltée (Les).1010 Entreprises Armand Houle Ltée (Ix's).1611 Entreprises Cobea Inc.(Les).1611 (îarand (Arsène) Inc.1611 Goodway Investment Co.1612 Immeubles François Simard Ltée (Les).1612 Industries Agricola Ltée (Les).1612 Institut de la Tour Inc.1634 International Enuresis Service Corp.Ltd.1613 Jover Corp.1613 Kelen Agencies Ltd.1613 Klein (John) Ltd.1614 Lake St.John Athletic Club Inc.1614 Laniel & Ma Ion in Inc.1614 Lansdowne Finance Corporation.1615 Larrivée (J.M.) Ltée.1615 Lehlond (J.-D.) Ltée.1615 Légion Canadienne de Kénogami Inc.(La).1616 Lemieux & Renaldy Ltée.1616 Lesage (Gérard) Inc.1616 Loisirs dc Saint-Sauveur des Monts Inc.(Les).1617 Lutins du Mont-Sutton, Limitée (Les).1617 Maimonides Hospital & Home for the Aged.1618 Marché Paul Inc.1618 Marché Roseval Inc.1619 Markal Inc.1619 Martin Steel Ltd.1620 Maurice Construction Inc.1020 Metroiwlitan Cold Storage Ltd.1610 Michaud (Léandre) Inc.1620 Midtown Hardware Distributor Corp.1621 Milot (Edgar) Ltée.1621 Mivillc (G.)-Déchêne Ltée.1621 Modem Frame Shop Ltd.1622 Monat & Bleau Limitée.1622 Moulding Products Ltd.1622 Nouveautés Mondiales Inc.1623 L'O.T.J.dc St-Côme, Beauce.1623 Ogilvy (Laurie C.) & Sons, Ltd.1623 Piché Nettoyeurs Inc.1624 Piette Oil Co.Ltd.1624 Plombe! ie Farnham Inc.1624 Poly-Star Mfg.Inc.1625 Precision Hydraulic Manufacturing Inc.1625 Quebec Camping Grounds Association.1603 Radio Sept-Ilionne lue.Restaurant Chinois Dragona Inc.1026 Restaurants Lemober Inc.(Les).|i,26 Riviera Chomedey Inc.(La).11,27 Roberge (Hubert) Inc.[>,¦>- Rosemount Junior Hockey Team Inc.itn)8 Roseval Market lue.Roy Beauty Manufacturing Co.Ltd.1627 Suint-Louis Auto-Locution Ltée.1628 Saint Louis Drive Yourself Ltd.|(J28 Salle d'Accueil Domrémy-Grand'Mèrc 1028 Bavard (Élène) Paulin Ltée.1628 SCOPInc.1629 Aldor Senneville Inc.[629 Société Internationale de Placements et de Gestion Ltée.1630 Société Philippe Simard Inc.(La).1030 Société Provinciale d'Évaluation Ltée 1636 Sodima Inc.1631 Sordini Concrete Ltd.1631 Soudure Dorion Inc.1032 Syme (C.) Upholstering Ltd.1632 Toledo Engine Rebuilders Inc.1032 Voyages Marcel Darche Inc.1633 Westminster Printing Corporalion.1633 Westward News Publishing Co.Ltd.(The).1633 Wolpert Cleaners Inc.1634 Lettres patentes Supplementary supplémentaires , Letters Patent Allied Finance Corp.1634 Carladan Investment Ltd.1635 Citroën Prestige Rentals Inc.1635 Crédit de l'Est Inc.1635 Crevier (Rimouski) Limitée.1635 Eastern Credit Inc.1635 Eastern Holdings Ltd.1636 Eleanor Ellis Ltd.loll.Falco Inc.1636 Finance Inter-City Inc.1037 Gaspesia Pulp and Paper Company Ltd.1036 fiend ron (Sylvio) Inc.1636 Greenoch Investments Ltd.1637 Greenoch Investments Ltd.1037 Henderson Furniture Limited.1037 Inter-City Finance Inc.1037 Laurent inn Car Centre Co.Ltd.1038 Laurentide Automobiles Inc.(1951).1638 Magasin Pembrooke Ltée.1038 Midtown Hardware Distributors Corp.1638 Monarch Securities Ltd.1039 National Wallpaper & Paints Limited (The).1039 Place Boulanger Limitée.1639 Placements Bergeron Limitée (Lee).1039 Prestige Rentals Inc.1040 Province Island Fishing & Came Club Inc.1040 Quebec Industrial Towels Ltd.1040 Radionette (Canada) Ltd.1040 Robitaille (L.A.) Automobile Inc.1640 Rouleau (Robert) Investments Ltd.1641 Serviettes Industrielles de Québec Ltée (Les).1640 Silver Stables Inc.1041 Traders Manufacturing Co.Ltd.1641 Trans-Canada Ropeways Ltd.1641 1215 Phillips Square Limited.1641 Sièges sociaux Head Offices Carladan Investment Ltd.R'75 Construction L'Abbé (Québec) Limitée.1070 Davis & Morin Ltée.1674 Delangis Inc.1076 L'Abbé Construction (Quebec) Limited.1676 Marché G.Loiselle Inc.1074 QUEBEC OFF WI AL GAZETTE, March 24, W62.Vol.!>4, No.12 mi Sieges sociaux Head Offices (suite) (continued) Miller Truck Leasing Corp.1074 Ogilvie (Laurie C.) & Sons, Lid.i «75 Precision Hydraulic Manufacturing Inc.1(175 Kouyn Dry Clean Inc.1676 Savard Paulin (Elene) Ltée.1675 Virob Investments Limited.1675 I M\" MANDES APPLICATIONS à la legislature to Legislature Duvernay, ville - town.1676 ( >u*remont, cité - city.1 (577 LIQUIDATION WINDING Caisse Populaire de St-Clément .1677 MiNISTÊRES DEPARTMENTAL \\ n ieiilture Agriculture Coopérative Agricole du Comté d'Ya- muska (Erratum).1077 Agriculture Agriculture Ord.36-62 (Granby).167S finances Finance Assurante! Insurance: Mutual Benefit Health and Accident Association (Nom changé - Name r hanged).1679 ln-i ruction publique Education .1/ uiiicipalitê scolaire de: School Municipality of: Bagotville, par.(Dem.- Appl.).1679 Last Bolton (Dem- Appl.).1680 Mugog, canton - township (Dem- Appl.).1680 Sacrc-Cœur-de-Jésus, par.et - and village (Dem.- Appl.).1080 St-Grégoire (Dem-Appl.).1080 Ste-Geneviève No.7 (Dem.- Appl.).1680 Hic liesses naturelles Natural Resources Révocation de droits de mines.1681 Revocation of mining rights.1681 Terres et Forêts Lands and Forests 1 adastre: Cadastre Laprairie de la Magdeleine, par.1681 Ste Beatrix, par.1681 transports Transportation et Communications and Communications Chemical fire extinguishers in autobusses, approval of models.1681 Extincteurs chimiques dans les autobus, approbation de modèles.1681 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Automobile, Québec (Prél- Levy).1692 Automobile, Québec (Appr.).1692 Automobile, Roberval (Prél- Lery).1694 Barbers and hairdressers, Magog (Amend.).1684 Barbers and hairdressers, Roberval (Amend.).1683 Barbiers, coiffeurs et coiffeuses, Magog (Mod.).1684 Barbiers, coiffeurs et coiffeuses, Roberval (Moi.).1683 Construction, Chicoutimi (Mod.- Amend.).1685 Construction, Duplessis (Mod.-Amend.) 1686 Dress, Province (Amend.).1086 Funérailles, Montréal (Prél.).1697 Funeral, Montreal (Levy).1697 Garage, Québec (Amend - Mod.).1682 Hardware, Quebec (Levy).1695 Quineuillerie, Québec (Prél.).1695 Robe.Province (Mad.).1686 Tanneries et Corroieries.Province (PnH.).1698 Tanners and Curriers, Province (Levy).1698 OFFICE QUEBEC des marches agricole» Agricultural du Québec Marketing Board Levis and Bellechasse Pulpwood Producers (Ilomol.).1701 Lotbinière Forest Products Producers (Ilomol.).-.1700 Megantic Forest Products Producers (Ilomol.).1700 Producers-Suppliers lo the St.Eustache Dairy (Receipt.).1702 Producteurs «le bois «le Lotbinière (Bornai.).1700 Producteurs «le bois «le Mégantic (llomol.)._.1700 Producteurs «le bois de pulpe «le Levis et Bel léchasse (llomol.).1701 Pioducteurs de bois «le pulpe du nord-ouest «|uébecois (llomol.).1701 Producteurs de bois de pulpe «lu Saguenay (llomol.).1701 Producteurs-fournisseurs «le la Crémerie de St-Eustache (Rccept.).1702 Quebec Northwest Pulpwood Producers (llomol.).1701 Saguenay Pulpwood Producers (llomol.) 1701 PROCLAMATION PROCLAMA TION Application à certaine territoires situés dans le district électoral «le Gaspé* Nord, des dispositions dc la Loi relative aux titres «le propriété dans lu Gaspésie et le district électoral de Saguenay.\u2022.1702 Application to certain territories situated in the electoral district of Gaspé-North, of the provisions of the Act respecting the title deeds in the Gaspcsian area and the electoral district of Saguenay.1702 SOUMISSIONS TENDERS Dolbeau, ville - town.1705 Drummondville, comm.scol.- school com m.1708 Hull, cité - city.1709 La Prairie, ville - town.1707 Orsainville.ville - town.1711 Salaberry-«le-Valleyfield, cité - city- 1706 SYNDICATS S i NDICATES Coopératif Cooperative Caisse Populaire St-Luc (La) - (Fond.- Found.).1712 Professionnel Professional Association «les Employés «le O.Beaudry & Fils Ltée (I/) - (Const.- Inc.).1712 1728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 24 mars 1962, Tome 94, No 12 VENTES SALES Effets non-réclamés Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company.1712 Licitation Licitation Toi m nui et al vs Ahrains.1713 Loi de faillite Bankruptcy Act St.Jean (S.) Automobiles Ltée.1714 SHÉRIFS SHERIFFS Beauharnois Beauharnois Salaberry «le Valleyfield, cité - city, comm.scol.- school comm.vs Dorais.1715 Bedford ¦ Bedford Bergeron (L.P.) Ltée vs Trudeau.1715 Chicoutimi Chicoutimi Central Mortgage and Housing Corporation.1716 Morin vs Maltais.1716 Société Central d'Hypothèque et de Logement vs Gagnon.1716 Gaspé Gaspé Couturier (A.) & Fils Ltée M Vallée .1717 Huit iiuii Chenier (J.P.) Co.Limited vs Good- fellow.1/20 McLaurin vs Grosvenor et al.1720 Uppadine vs Cardinal.1720 Western Quebec Construction Ltd.vs Aylmer Park Development Corp.1717 Mégantic Mégamic Labrecque il Guérartl.17 2 ! Montréal Montr, al Century Credit Union (Lachine) Ltd.vs Ockendcn.1/22 Perrault (Léo) Ltée vs Champagne.17-2 Québec Queht-i Sainte-Foy, cité - city H Bertrand.1722 Roberval Robert ni Hollinger Machines Co.Ltd.vs Girard.1723 Office du Crédit Agricole du Québec vs Gagné.1723 Quebec Farm Cre«lit Bureau vs Gagné.17 23 Saint-Hyacinthe Saint Hyacinthe Côté es Lach an ce.172-1 Taxes Taxes Argenteuil, comté de - county of.1644 Dorchester, comté de - county of.1642 L'Imprimeur de la Reins, ROC H LEFEBVRE, Queen's Printer \u2014 Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.