Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 22 (no 38)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1962-09-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Tome 94, No 38 4769 Vol.94, No.38 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI, ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Quebec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Québec, samedi 22 septembre 1902 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspoiulance à: l'Imprimeur «le la Reine.H«\">tel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte «le l'annonce «lans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule lungue.la traduction en est faite aux frais «les intéressés, «l'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre «l'inscrtions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-«less«)iis.( dependant, exception est faite lorsque ces annonces elow set forth.Exception being made when the said advertising Copy is to be published several times.The interested pi.rty shall then pay upon reception «>f his account and befoic the second insertion: otherwise this last insertion will he suspended without further .notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all eases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale «>f documents, etc., are strictly payable in advance.L'Imprimeur de la Reine, ROC 11 LEFEBVKE, Queen't Printer \u2014 Québec 4770 GAZETTE GEE II l EUE DE QUÉBEC, H septembre 1962, Tome 94, So 38 6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Heine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La llarjttc officielle de Qutbec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le mercredi à condition que ce jour de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans un tel cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documente ou annonces r«\\us en retard sont publics dans une édition subséquente.De plus, ['Imprimeur de la Heine a le droit «le retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.H° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Heine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, «le paît et «l'autre des frais onéreux «le reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agale, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate poi r chaque version.La matière tabulaire (listes «le noms, «le chiffres, etc.) est comptée double* Traduction: $1 des 100 mots.Exemplaire séparé: 10 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Abonnement: $10 par anmV.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui «le l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui «lu nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis «pie de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, Kocii Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec.5 mai 1902.59870 \u2014 l-52-o Lettres patentes Arizona Company Ltd.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de juin 1902, constituant en corporation: Seymour Avrith, Jean-Louis Lamoureux, avocats, et Jacqueline Lalibeité, secrétaire, célibataire, tous de 180 est, rue Dorchester, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commence «l'entrepieneurs géné-taux et constructeurs, sous le nom de « Arizona Company Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.6.Remittuice must be made to the or«|er «>f the Queen*! Printer, by accepted cheque, by bank «>r postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Werc the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for eacl.version.(14 lines to the inch, namely 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $1.per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number ; the second to that of the edition of the Gazctti for the first insertion; the third to the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our «locument number.Rocu Lefebvhe.Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec, May 5, 1902.59870 \u2014 1-52 « Letters Patent Arizona Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing ! 180, Dorchester Street East, Montreal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Arizona Com pany Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divide*! into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 196», Vol.94, No.36 4771 lf \"Associated Senior Executives «>f Canada Inc.\".with a total capital stock of $1.500.divided into 1,600 shares of a par value «>f $1 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the ofliee of the Provincial Secretary, this 10th day of July, 1902.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.613-o 121 (il-02\u2014 1134/131 At Ian tic-Pacific Travel (Canada) Inc.At Ian tic-Pacific Travel (Canada) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 12e jour «le juillet 1962, constituant en corporation: Frank F.Hubscher.avocat.6701, chemin Kirwan, Côte-St-Luc, David Rothenberg, comp-table agréé, 573, avenue Rockland, Montréal, David Luterman, comptable agréé, 5561, Bradford Place, Montiéal.et Fernand Yelle, gérant de (instruction, 9005.rue Chateaubriand.Montréal, pour Tes objets suivants: Exploiter un service d'agence «le voyages, sous le nom de « Atlantic-Pacific Travel (Canada) Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.I .(\u2022 siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 12e jour de juillet 1962.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Darveau.'il 3 12724-62\u2014 1135/110 Bale-Tie Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de juillet 1962, constituant en corporation: Max Coblentz, avocat, Hélène Josephs, Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 12th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Frank F.Hubscher.advocate.6701, Kit wan Road, Côte-St-Luc, David Rothenberg, ehartere«l accountant, 573.Rocklanil Avenue, Montieal, David I.utciman.chartered accountant.5561.Biadford Place, Montreal, and Fernand Yelle, building manager, 9005, Châteaubiian«l Street, Montreal, for the following purposes: To carry on a travel agency service, under the name of \"Atlantic-Pacific Travel (Canada) Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of July, 1902.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.613-o 12724-62\u2014 1135/110 Bale-Tie Corp.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 4th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Max Co-blent z, advocate, Helene Josephs, secretary, 4772 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 septembre 1962, Tome 91 No 38 secrétaire, fille majeure, usant «le ses droits, et Joseph Allai d, surinteiulant, tous trois «le 484.rue Me Ci II, Montréal, pour les objets suivants : Faire le commerce «le toutes sortes «le fournitures d'emballage et la mise en balles, sous le nom «le « Bale-Tie Corp.», avec un capital total «le 140,000.divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 3,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, distiict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 4e jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire, tie la prorince, S a y.m on I) 1 )f \"Bale-Tie Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares «>f $10 each ami 3,000 preferred shares of $10 each.The bead office «>f the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day ©I July.1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 12845-02 \u2014 1134/05 Balthazar Automobiles Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ia>\\ des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 5e jour «le juillet 1902, constituant en corpo-ration: Jean-Marie Brassant 11778, rue De Tracy, Robert Ilamel, 10429, rue Oscar, tous deux «le Montréal, et Jae«pi«\\s-A.Belisle.348.route Nationale, Bois-des-Filion, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines, leurs accessoires et parties, et faire affaires comme garagistes, sous le nom «le « Balthazar Automobiles Inc.», avec un capital total «le $40,000.divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $100 chacune «it en 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 15951, rue Notre-Dame, est, Pointe-aux-Trembles, distiret judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce Se jour «le juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouviLLB.613*0 12843-02\u2014 1134/20 Guy Bertrand Dairy Queen Limited Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie «!«\u2022 la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 13e jour de juillet 1902, constituant en corporation: Krrol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, tous deux avocats et conseils en loi «le la Reine, et Herbert Birkett McNally, avocat.tOUS trois «le 507.Place «l'Armes, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le produits laitiers, sous le nom «le « Guy Bertrand Dairy Queen Limit-ed ».avec un capital total «le $1,000, divisé en 1.000 actions ordinaires «le $1 chacune.Ia* siège social «le la compagnie seta à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 13e jour «le juillet 1902.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Dakveau.013 12607-62\u2014 1134/J 04 Bodi, Wicdmumi & Co.Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date Balthazar Automobiles Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of July.1902, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Jean-Marie Brassard, 11778, De Tracy Street, Robert Haincl.10429, Oscar Street, both of Montreal, and Jacques-A.Bel isle, 348.route Nationale, Bois- des-Filion, all three advocates, for the following purposes: To carry on business dealing in automobile-, motors, machines, their accessories and part-, and to act as garagemen, undei the name of \"Balthazar Automobiles Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The bead office of the company will be at 15951, Notre-Dame Street east, Pointe-au.v-Trembles, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of July, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013 Ï1S43-02 \u2014 1134 20 Guy Bertrand Dairy Queen Limited Notice is hereby given that undei Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July.1902, haw been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Krrol Klock McDougall, Walter Austin Johnson, both advocates and Queen's Counsels, and Herbert Bbketl McNally, advocate, all three of 507, Place d'Armes, Montreal, for the following purposes: To deal in dairy products, under the name ol \"Guy Bertram! Dairy Queen Limited\", with a total capital stock of'$1,000.divided into 1,000 common shares of $1 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary.this 13th .lay «>f July.1902.Lucien Dadveau, Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 12007-62\u2014 1134/101 Bodi, Wiedmann & Co.Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 1062, Vol, 04, No.38 4773 du !)e jour «le juillet 1962, eonstituant en corpora-tiori: Alfre«l Melrose West, avocats.4558, avenue Kensington.Montréal, Michael Husko, avocat, .'5117, The Boulevard, Montréal, David Gregory, avocat, 21H, avenue Morrison, Mont-Royal, Helen May Buchan, secrétaire, veuve non remariée «le feu Iluntly Buchan.5542, avenue Cool-brook, Montréal, et Albert Pashei, surintendant ,!«¦ construction, 6516.avenue Cluistophe-Colombi Montréal, poill les objets suivants: Kxereer dans toutes ses s|>éeialités le commerce de courtiers en assurance, sous le nom «le « Bodi, Wicdmann & Co.Limited ».avec un capital total «le $10.000, divisé en 5.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune et 5,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $1 chacune.Le siège social «le lu compagnie sera 400 ouest, rue St-Jacques, Montréal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le lu province, ce 9e joui de juillet 1902.té Sous-secrétaire adjoint de la province, Ldciex- Dab veau.613 11197-02-1135/112 Boivin & Lcgatilt Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ixn «les compagnies de (Québec, il a «\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Quél>ee.«les lettres patentée, en date du lie jour de juillet 1902.constituant en corporation: Marc Jessop, 2748, boulevard Liégeois, Stc-Foy, André Maiceau.212.Grande-Allée, est, tous deux avocats, et Jean-ur les objets suivants: Exercer le commerce «le courtiers en assurance, sous le nom «le « Boivin & Legaull Inc.».avec 1:11 capital total de $40,000.divisé en 50 actions ordinaires de $100 chacune et en 350 actions privilégiées «le $100 chacune.I.e siège social «le ia compagnie sera 111, Côte de la Montagne, Quélier, «listriet judiciaire de Québec, Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1 le jour de juillet 1962.7.e Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Dahvkau.6l3-o 12924-62\u2014 1134/126 L.A.Brahm & Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la toi des compagnies de Quebec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 5e jour de juillet 1962.constituant en corporation: Léo A.Brahm, marchand, Elsie Hi alun, comptable agréé, «'-pouse séparée de biens dudit Iiéo A.Brahm.et dûment autorisée par ce dernier aux fins des présentes, tous deux de 2173, Chemin St-Clare, Mount Royal, et Mlle Garda Wolf, secrétaire, 5625, avenue Emerald, Côte St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce de textiles et «le nouveautés, sous le nom de « L.A.Brahm & Company Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.te ss de l'immeuble et «le la construction, sous le nom de « D.& H.Realties Inc.», avec un capital total de $10,000.divisé en 100 actions «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 3e jour «le juillet 1962.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.613 12822-62 \u2014 1134/120 To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Crazy Horse Saloon Inc.\u2014 A I'Kn seigne du Cheval Fringant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of a par value of $100 each and 2,000 preferred shares id a par value of $10 each.The bead office of the company will be at 5408, Cote-des-Neiges, Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 13th «lay of July.1902.Lucien Dauveau, Associate Assistant Secretan/ of the Province.613 12998-62 \u2014 1134/80 D.& II.RealtieH Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 3rd day of July, 1962, bave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Hyman En gel, mortgage broker, 6484,.Victoria Avenue, Montreal, Stanley Haltrecht, notary, 795, Bertrand Avenue, St-Laurent, and Josh Abrahams, student, 4790, Plamondon Avenue.Apt.301.Montreal, for the following purposes: To do business in the fields «>f real estate ami construction, umler the name of \"D.& II.Realties Inc.\", with a total capital stock of $10,000.divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of July, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.613-o 12822-62 \u2014 1134/121' Dawn Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 6e jour de juillet 1962, constituant en corporation: Michel Jutrzenka, constructeur.Mme Mary Jutrzenka, ménagère, épouse séparée de biens dudit Michael Jutrzenka, et dûment autorisée par ce «lernire aux fins des présentes, tous deux de 4840, avenue Maplewood.Montréal et Mlle Janet Samit, secrétaire, 2530, avenue Van Home, Montréal, pour les objets suivants: Exercer «les affaires dans les domaines de l'immeuble et «le la construction, sous le nom de « Dawn Construction Inc.», avec un capital total de $10,000.divisé en 1,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4840, avenue Maplewood, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 6e jour de juillet 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.613 12884-62 \u2014 1134/43 Distribution du Meuble Villeneuve Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juillet 1962, constituant\" en cor- Dawn Construction Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating: Michael Jutrzenka, builder, Mrs.Mary Jutrzenka, housewife, wife separate as to property of the sai«l Michael Jutrzenka, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 4840.Maplewood Avenue, Montreal, and Miss Janet Samit, secretary, 2530, Van Horne Avenue.Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Dawn Construction Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 shares of $10 each.The hea«l office of the company will be at 4840, Maplewood Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 0th day of July, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Provirwe.613-o 12884-62 \u2014 1134/43 Distribution du Meuble Villeneuve Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Harry Ville- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 1962, Vol.94, No.38 4779 poration: Harry Villeneuve, industriel, 125, rue St-David, Chieoutmi-Nord, Paul Simard, comptable agréé, '.il, rue Racine, ouest, Chicoutimi, et Madeleine Drapeau, secrétaire, célibataire 154, rue Racine, est.Chicoutimi, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et de nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Distribution du Meuble Villeneuve Inc.», avec un cupital total de $30.000, divisé en 3,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chieouti-mi-Nord, district judiciaire de Chicoutimi.Donné au bureau du secrétaire de lu province, ce 10e jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, LtJCIBN D as veau.613-0 12805-02- 1134/81 neuve, industrialist, 125, St-David Street, Chi-coutimi-North, Paul Simard, charteied accountant, 31, Racine Street west, Chicoutimi, and Madeleine Drapeau, secretary, spinster, 154, Racine Street eust.Chicoutimi, for the following pu r | Mises : To deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Distribution du Meuble Villeneuve Inc.\".with a total capital stock of $30,000, divided into 3,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Chicoutimi-Xorth.judicial district of Chicoutimi.(îiven at the office of the Provincial Secretarv.this 10th day of July.1902.Lucien Dab veau.Associate Assistant Secretary of the Province.013 12805-02 \u2014 1134/81 Domaine du Plateau Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du lie jour «le juillet 1902, constituant en corporation: Jean-Louis Maurice, vendeur, Yves Lépine, entrepreneur, tous deux «le Mont-Rolland et Alain Voixard, notaire, Ste-A«lèle-en-Haut.pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines «le l'immeuble «¦t «le la construction, sous le nom de « Domaine du Plateau Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $10 chacune et en 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Mont-Rolland, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce lie jour de juillet 1902.Le Sous-secrêtaire adjoint de la province, Lucien Darveau.013-o 12712-02\u2014 1135/16 Dual Quebec Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 27e jour «le juillet 1962, constituant en corporation: Ernest William Mockridge, gérant de bureau, William Patrick Creagh, commis en Loi, Guy AmbioseMiller, teneur de livres et John Lawrence Me Crory, commis en Loi, tous quatre de 360 ouest, rue St -Jacques, Montréal, poui les objets suivants: Faire le commerce des pièces constituantes d'appareils électriques et électroniques accessoires et dispositifs et toutes sortes «le dispositifs servant à l'enregistrement et à la transmission, sous le nom de « Dual Quebec Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.613 ' 12932-62 \u2014 1136/8 Diimont Ventilation Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Domaine du Plateau Inc.M Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Louis Maurice, salesman, Yves Lépine, contractor, both of Mont Holland, and Alain Voizard, notary, Ste-Adèle-en-Haut, for the following purposesi To carry on business in the field of real estate and construction, under the name of \"Domaine du Plateau Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferml shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Mont -Holland, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July, 1962.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.613 12712-62\u2014 1135/16 Dual Quebec Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 27th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ernest William Mockiidge, office manager, William Patrick Creagh, law-clerk, Guy Ambrose Miller, bookkeeper, and John Lawrence McCrory, law-clerk, all four of 360, St.James Street West, Montreal, for the following purposes: To deal in electrical and electronic components, apparatus and devices an«l recording and trans-metting devices of all kinds, under the name of \"Dual Quebec Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4.000 shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of July, 1962.Raymond Dot:ville.Assistant Secretary of the Province.613-o 12932-62\u2014 1136/8 Dumont Ventilation Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act letters patent, bear- 4780 OAZETET OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 1962, Tome 9/,, No SX été accordé, par le lieutenant -gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 5e jour «le juillet 1902, constituant en corporation: Jean-IiOiiis Lefebvre.avocat, 3518, Af $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the 1'rovincial Secretary, this 5th day of July.1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.613 12830-02- 1134/72 Elda Construction Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 11th day of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard-E.Blanchard, advocate, 105, 3rd Avenue South, Roxboro, Yolande Galardo, 9047 Millen Street, and Marlene Lacroix, 9160, St-Michel Boule-vard, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Elda Construction Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretarv.this 11th day of July.1902.Lucien Dahveau, Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 12551-02- 1134/134 Eldon Star House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Edward I.Auerback, advocate ami Queen's Counsel, 250, Kensington Avenue, Westmount, Boris J.Berbrier, advocate, 4851, Fulton Street, Montreal, Mark Edmund Gordon, advocate, 30, Roxborough Avenue, Westmount, an«l Madeline Ferguson, secretary, spinster of the full age of majority, 1460, McGregor Street, Montreal, for the following purposes: To manage, represent and book actors, pref-ormers, musicians, singers and other entertainers, and to act as agents for such artists and entertainers, under the name of \"Eldon Star House Inc.\", with a total capital stock of $1,000, divided into 1,000 ocommon shares of the par value of $1 each.The head office of the company., will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July.1902.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.613-o 12809-62\u2014 1134/135 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Setpember 22, 1M2, Vol.H, So.SH 4781 Klmar Automotive Accessories Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Lii des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 13e jour de juillet 1902, constituant eu corporation: Louis Moses (îomberg, marchand.Esther (îomberg, ménagère.é|M>usc séparée «le biens dudit Louis Moses (îomhcrg, tous deux «le 5568, avenue ltos«'dale.Côte St-Luc, et Albert Goinl>erg, avocat, 7145, avenue Chester, Montreal, pour les objet- suivunts: Exercer le eommcree «le marchandises d'automobiles, «le radio, «l'électricité, «le «piincaillerie, ménagères et soprtives, dis|M>sitifs, fournitures «\u2022t articles «le toutes sortes, sous le nom de « Klmar Automotive Accessories Lt«l.», avec un capital total de $40,(XM), divisé en l.(HK) actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégieea «le $1(M) chacune.1a* siège social «le la compagnie sera 7131.chemin Cote St-Luc, Montréal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 13c jour «le juillet 1902.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Dahvkau.013 12975-02- 1135/119 Les Employeurs Forestiers de la Maiiricie, Inc.Avis est donné «pi'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnie- de Quélrec, il a «;té accordé, |>ar le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 13e jour «l'août 19152, constituant en corporation sans capital-actions: François La joie, ch., avocat.Isabelle Vigneau «'t Lunette Vigneau, secrétaires, filles majeures, tous trois de Trois-Rivie-res.pour les objets suivants: Promouvoir et défendre les intérêts «les employeurs forestiers engagés dans l'exécution «l'onérations forestières dans les concessions forestières et dans les forêts privés «le la Canadian International l'a|>er Company, sous le nom «le I Les Employeurs Forestiers «le la Mauricie.Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers «pie la corporation peut posséder, est «le 825,000.Ix' siège social de la corporation sera à Trois-Rivières, district judiciaire «le Trois-Rivières.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 13e jour d'août 1902.Le Sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douviixk.013 13373-62\u2014 1139/29 Farha Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 9e jour «le juillet 1962, constituant en corporation: E«lward (t.Tannage, avocat et conseil «\u2022il loi de la Reine, André Valiquette.avocat, et Jeannette Des jardins, sténographe, fille majeure, tous trois «le 159, ouest, rue Craig, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes d'articles vestimentaires, sous le nom «le « Farha Agencies Ltd, », avec un capital total «le $40,000, divisé en 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune et 200 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.Elrnar Automotive Accessories Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louil Moses (îomberg, store-keeper, Esther (iomberg, housewife, wife separate as to property of the said Louis Moses (îomberg, both of 5508, Rostnlalc A verrue, Côte St-LlIC, ami Albert (îomberg, advocate, 7145, Chester Avenue, Nb.nl real, for the following purposes: To «l«'al in automotive, radio, television, elec-tricaJ, hanlware, houseware ami s|M>rting good-, appliances, supplies and articles of all kinds, under the name of \"Klmar Automotive Accessories Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each ami 800 preferred shares of $100 eeah.The head office of the c«>mpany will Ire at 7131, Cùle St-Luc Road, Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of July, 1962.Lucien Dahvkau, Associate Assistant Secretary of the Province.613-o 12975-62 \u2014 1135/119 Les Employeurs Forestiers de la Mauricie, Inc.Notice is hereby given that umler l'art III of the Quebec Conipani«\\s Act.letters patent, bearing «late the 13th day of August, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «»f Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: François Lajoie, Q.C., advocate, Isabelle Vigneau ami Lunette Vigneau, secretaries, filles majeurs, all three of Trois-Rivières, for the following purposes: To promote ami defend the interests of forestry employers engaged in the execution of forestry operations in forestry concessions ami in private forests of the Canadian International Paper Company, under the name of \"Les Employeurs Forestiers de la Mauricie, Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25.000.The bead office of the corporation will be at Trois-Rivières.judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of August.1962.Raymond DOUVILLE, Assistant Secretary of the Province.613 13373-62 \u2014 1139/29 Farha Agencies Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th «lay of July, 1902.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f (Quebec, incorpoiatiug: Kdwurd G.Tannage, advocate and Queen's Counsel.André Valiquette, advocate, ami Jeannette Desjardins, stenographer, spinster of the full age of majority, all three «>f 159, Craig Street West, Montreal, for the following purposes: To deal in wearing apparel of all kinds, umler the name of \"Farha Agencies Ltd.\", with a total capital Stock of $40.000, divided into 2.000 common shares of the par value of $10 each and 200 preferred shares of the par value «»f $100 each. 4782 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 1962, Tome 94, Au 88 Ia' liège social de la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, 00 9c jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire adjoint de la prorince, Lucien Dahvkau.013 12895-02\u2014 1134/109 Faro Industries (1962) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 5e jour de juillet 1902, constituant en corporation: Lionel Tremblay, administrateur, 2072.Lebrun, Montréal, John Ewasew.340, avenue Burton, et .1.Arch'u Blakely, 170.avenue Morrison, ces deux derniers avocats, de Mont Royal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et «l'eutrepreneurs généraux, sous le nom «le « Faro Industries (1902) Ltd.», avec un capital total «le $40.000, «livisé en 10.000 actions ordinaires «le $1 chacune, 0.000 actions privilégiées «le $5 chacune.Le Siège social de la compagnie sera 9480 est, rue Notre-Dame, Montréal, district ju«liciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 5e jour «le juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.013 12510-02\u2014 1134/83 The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the l'rovincil Secretary, this 9th day of July, 1902.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 12895-02 \u2014 1134/100 Faro Industries (1962) Ltd.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing data the 5th day f July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province ot Quebec, incorporating: Lionel Tremblay, executive, 2072, Lebrun, Montreal, John Ewasew, 340, Barton Avenue, und J.Arclen Blakely, 170, M«>rrison Avenue, the latter two advocates, of Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business «»f builders ami general contractors, umler the name of \"Faro Industries (1902) Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 10.000 commno shares of $1 each, 0.000 preferred shares «>f $5 each.The bead office of the company will be at 9480, Notre-Dame Street East, Montreal, jmlicial district of Montreal.(«iven at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of July, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.613-o Ï 2516-62 \u2014 1134/83 Foss Sales Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1961, constituant en corporation: Edward G.Tannage, Gérard Hévert, avocat et conseil en loi de la Reine, et Jeannette Desjardins, sténographe, fille majeure, tous trois «le 4 est, rue Notre-Dame, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le produits, articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie «le cuir, caoutchouc, métal, bois, papier, nylon, plastique, fourrure, textiles, verre et sous produits d'iceux; articles de mercerie, produits alimentaires, animaux, minéraux, pierres précieuses, eaux gazeuses, livres et périodiques, peintures, oeuvres d'art, produits chimi«]ucs, produits de la terre, de la mer et de la forêt, produits «le beauté, cosmétiques, articles de toilette et parfums, sous le nom de « Foss Sales Agencies Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 4e jour de septembre 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.613 15867-61 \u2014 1107/109 Foss Sales Agencies Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th day of December, 1901.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Edward G.Tannage, Gérard Hébert, advocates anil Queen's Counsels, ami Jeannette Desjardins.stenographer, spinster of the full age of majority, all three of 4 Notre-Dame Street East, Montreal, for the following purposes: To deal in products, articles and merchandise made, in whole or in part, of leather, rubber, metal, wood, paper, nylon, plastic, fur, textiles, glass and by-products of same: in haberdashery, food products, animals, minerals, precious stones, soft drinks, books am! periodiacls, paintings, works of art, chemical products, land, sea and forest products, beauty prcxlucts, cosmetics, toilet articles and perfumes, under the name of \"Foss Sales Agencies Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of September, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 15807-01 \u2014 1107/109 R.W.Galbraith and Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 13e jour de juillet 1902, constituant en corporation: Jacques Béïque, avocat, 9135, boule- R.W.Galbraith and Company Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Bél-ques, lawyer, 9135, LaSalle Boulevard, LaSalle, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, J 969, Vol.94, So S8 4783 vard IjiSallo, I-aSalIe, (Ycilien Pelchat, avocat, '.105, Marseille, Montréal, André Hélque, ingénieur professionnel, 5120, McDonald, app.301, Côte St-Luc, Jacqueline Lapierre, secrétaire, célibataire, 758, Gilford, Montréal, et Stefania Alpern, secrétaire, veuve «le Witold Ko/l«)\\vski, 3581, Ste-Famille, Montreal, p«>ur les objets >uivants: Faire le commerce de moteurs, chaudières, générateurs d'usines, toutes sortes d'outillages pour travaux hydruulupies, outilluges pour exploitation minière et iiulustrielle, toutes sortes d'instruments et outils, camions-automohiles et accessoires, aéroplanes et accessoires.Imtcaux à vapeur, remorqueurs «-t autres appareils flottants, -ous le nom «h' « R.W.Galbraith and Company Ltd.», avec un capital total «le $10.000, divisé en 2,000 actions ordinaires «?Sous-secrétaire adjoint de la prmnnce, Lucien Dahvkau.013 12570-02\u2014 1134/110 Loui- A.Cauthier Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du (k* jour «le juillet 1902, constituant en corporation: Louis-A.(iauthier.courtier en assurance, 1301, avenue Lcclair, Verdun, Pierre-Paul Vali-ipjette, comptable, 220, 4e avenue, LaSalle.et lean-A.Viau, comptable, 1312, rue Valiquette, Verdun, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers en assurance, -ous le nom de « Louis A.(iauthier Inc.», avec un capital total de $10.000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.I^e siège social de la compagnie sera à Verf \"R.W.Galbraith ami Company Ltd.\", with a total capital stock of 810.000.divided into 2.000 common shares «>f $10 each and 200 prefer-red shares of $100 each.The bead office of the company will be at 2025.Albert Street.Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of July, 190.2.Lucikn Dahvkau, Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 12570-02 \u2014 1134/110 I.oui- A.Gauthier Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 0th «lay «»f July, 1902.have been issued by the Li«'utenant-Governoi of the Province of Quebec, incernorating: Louis-A.(iauthier.insurance broker, 1301.Leclair Avenue, Verdun, Pierre-Paul Valitpiette.accountant, 220, 4th Avenue, LaSalle.ami Jean-A.Viau, accountant, 1312.Valitpiette Street.Verdun, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers, umler the name of \"Lotus A.Gauthier Inc.\", with a total capital stock of $1.0.000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Verdun, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this Oth day of July, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.G13 12189-02\u2014 1134/84 Guillicit Spring Service Inc.Avis est «lonné.qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a f Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of June, 1902.Raymond Douvim.k, Assistant Secretary of the Pwvince.013-o 12555-02 \u20141183/42 Jaloby Enterprises, Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 1th «lay of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating: Neil F.Phillips, advocate, 634, Clarke Avenue, Westmount.Melvin Rothman, advocate, 638, Roslyn Ave nue, Westmount, an«l Miss Margaret Bank-, secretary, fille majeure, 7H, Roxton Crescent, Montreal West, for the following purposes: To carry on the business of theatrical agent -and artists' agents, under the name of \"Jaloby Enterprises, Inc.», with a total capital stock of $5,000, divided into 1,000 common shares of each.The head office of the company will be at Saint -Laurent, judicial «listriet of Montreal.(Jiven at the office «»f the Provincial Secretary, this 11th day of July, 1902.LtJCIBN Dakvkai , Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 12944-62- 1136 12 I.M K Investment Corp.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letteis patent, bearing date the 11th day of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Charles Brownstein, advocate.6612, Nice Road, Côte-St-Luc, Mary Goldwater, secretary, wife sepa rate as to property of Sydney L.Gold Water, 4155, Dupuis Avenue, Montreal, and Harold Archer, secretary, 3160, Granby Street.Montreal, for the following purposes: To f tin-par value of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at.the office of the Provincial Secretary, this 11th day of July, 1902.Lucikn Dakvkau, Associate Assistant Secretary of the Province.G13-o 12943-02 \u2014 1134/140 QUEBEC OFFICIAI, GAZETTE, September 22, 1962, Vol.94, So.3S 47S5 A.I.as-omlc & Fils Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partit de la \\ah des compagnies de Québec, il u \u2022 té accordé, par le lieutenant gouverneur de lu province de Québec, des lettres patentee, en date lu 3e Jour de juillet.1962, constituant en corporation: J.-Willie Lassonde.Jean-( 'lande Lasscndc it Léandrc Lassonde, tous trois industriels, de i'iiiigemout, pour les objets suivants: Exercer le commerce de produits alimentaires, *OUS le nom de « A.Lassonde & Fils Inc.».avec in capital total de 1200,000, divisé en 1,000 i et ions ordinaires «le $100 chacune «-t en 1,000 Lctiom privib'gitVs de $100 cliacunc.I«e siège aocial de la compagnie sera à Rougc-nont, comté «le Itou ville, «listriet judiciaire de \u2022t-Hyacinthe.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, e 3e jour «le juillet 1962.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Dor ville.;|.{-o 12X11-62 1134/27 Loyer & Fils Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Quebec, il a lé accordé, par le lieutenant-gouverneur de la \u2022rovinee «le Québec, des lettres patentes, en «late du 18e jour «le juillet 1962.constituant en corporation: Claiule-Réal (liranl, étudiant, Solange Pesant, secrétaire, fille majeure, et Rita Cbagnon, ménagère, veuve non remariée «le Gaston Cha-\u2022uon, tous trois de 6083, boulevard St-Laurent, dontréal, |>our les objets suivants: Kxercer le commerce «le constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Loyer & Fils Ltée », avec un cupital total île $10,000, divisé en 100 uctions de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire «le Ni ont réal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce ISe jour de juillet 1962.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Darveau.613-o 12719-62\u20141135/25 A.Lassonde & VU- Inc.Notice is hereby given that Under Part I f \"A.Lassonde & Fils Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1.000 common shares of $100 each ami 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Rougemont, county of Rouvillc.judicial «listriet of St.Hyacinthe.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day «>f July.1962.Raymond Doivii.i.k, Assistant Secretary of the Province.613 12811-62 - 1134/27 Loyer & Fils Ltée Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the lSth «lay of July.1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude-Seal Girard.-Indent.Solange Pesant, secretary, fille majeure, ami Rita Chagnon, housewife, unremarried widow of Gaston Chagnon.all three of 0983, St.Lawrence Boulevard.Montreal, for the following purposes: To cany on business as builders ami general building contractors, umler the name of \"Loyer & Fils Ltée\".with a total capital stock of $10.000.divided into 100 shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, jmlicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretarv, this 18th day of July.1962.Lucikn Dakvkau, Associate Assistant Secretary of the Province.613 i 2719-62\u2014 1135/25 Lubert Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de»Québcc, il a dé accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la piovince «le Québf \"Lubert Sportswear Inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 10.000 common shares t>f a par value of $1 each ami 30,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the compauy will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of June.1902.Raymond Douville, Assistant Secretan/ of the Pwvince.613-o 12677-02 \u2014 1133/02 4786 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 .septembre 1962, Tome 94, A'o 38 Mîhh Chinatown Soul li Shore) Lid.Miss Chinatown (South Shore) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 19e jour «!«¦ juillet 1962, constituant en eorpo- ration: Kwong Sun Hum, 4K36, rue Hutchison.Montreal, Chuck Sin Hum, 811, At water, Montreal.Lai Cho Hum.4836, rue Hutchison, Montreal.Ken Kin Hum, 216.est, Villeneuve, Montreal.Cheng Mei Hum, 216 «-st, Villeneuve, Montreal, et Wong Kuen Yee.3680, rue Gertru* «le.Verdun, tous six cuisiniers, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le restaurateurs, sous le nom de « Miss Chinatown (South Shore) Ltd.», avec un capital total de 890,000, divisé en 100 actions ordinaires de §100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le Siège social «le la compagnie sera à Saint-Lambert, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «\u2022«\u2022 19e jour de juillet 1962.Ije Sous-secrétaire adjoint de la province, Lucien Dahvkau.613 13057-02\u2014 1135/128 Movie Star Lingerie Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie «le lu Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, pur le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 5e jour de juillet 1962, constituant en corporation: Bella Luxenburg Shapiro, ménagère, «:pou-se séparée de biens de Joseph Shapiro, Esther Marie Shapiro, dessinât rice, célibataire, toutes deux de 1400, avenue McGregor, app.602, Montréal, «\"t Deena Miller, secrétaire, célibataire, 3517.avenue Vendôme, Montreal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de toutes suites «le lingerie, sous le nom «h' « Movie Star Lingerie Inc.».avec un capital total «le $50,000, divisé en 250 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $100 chacune et 250 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montreal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 5e jour «le juillet 1962.Le Sous-secrétaire de la province, Ratmono Douville.613 12858-62\u2014 1134/31 Notice is hefeby given thut uiulef Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing dat«' the 19th «lay of July, 1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province t, Verdun, all six Cooks, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Miss Chinatown (South Shore) Ltd.\", with a total capital stock of $30.000, divided into 100 common shares of $100 each ami 200 preferred shares of $100 each.The bead office «»f the company will be at Saint-Lambert, judicial «listriet of Montreal.Given at the otfice of the Provincial Secretary, this 19th day of July, 1902.Lucien Dakvkau, Associate Assistant Secretary of the Province.013-o 13057-02\u2014 1135/128 Movie Star Lingerie Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 5th «lay of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Québec, incorporating: Bella Luxenburg Shapiro, housewife, wife separate as to property of Joseph Shapiro, Esther Marie Shapiro, designer, spinster, both of 1400.McGregor Avenue, Apt.002, Montreal, ami Deena Miller, secertary, spinster, 3547.Vendôme Avenue, Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of lingerie, undei the name of \"Movie Star Lingerie inc.\", with a total capital stock of $50.000, divided into 250 common shares of the par value of $100 each ami 250 preferre«l shares of the par value of $100 each.The bead oflice of the company will be at Montreal, jmlicial «listriet of Montreal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 5th day of July.1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 1* 2858-02 \u2014 1134/31 Northeraft Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 9e jour de juillet 1902.constituant en corporation: Irving Hulpcrin, avocat, 4827, avenue Kent.Montreal, Daniel Morris, avocat, 4502, Laconihc, Montreal, et Ernest R&shkovan, noaire, 4780, avenue Vé/.ina, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le bateaux, aéroplanes, biplanes, machines et appareils volants, hydroplanes ou nutomihiles, sous le nom de « Northeraft.Industries Ltd.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Northeraft Industries Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th day of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Irving Hal-perin, advocate, 4827, Kent Avenue, Montreal, Daniel Morris, a«lv«>eate, 4502, Lacombe, Montreal, ami Ernest Rashkovan, notary, 4780, Vésina Avenue, Montreal, for the following purposes: To deal in boats, aeroplanes, biplanes, machines^ flying apparatus, hy«lroplanes or automobiles, under the name of \"Northeraft Industries Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 prefer-re«l shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 196$, Vol.94, So.38 4787 Dunné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce Be jour «le juillet 1002, Le Sous-secrétaire ad juin! île la prorinre, LuCfBM Dahvkau.613 12900-02\u2014 1135/131 Pioneer Textiles Co.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Iur «le juillet 1902, «-oust it liant en corporations Stanley Hlusteiu.maieliund.Samlra Lyman Bluetein, ménagère, ëpouae séparée «le iriens dudtl Stanley Bluetein, et dûment autorisée pur «r dernier aux fins dee presentee, tous deux de 1085, rue Notre-Dame.Cliomedey, et Henry Bluetein, Reran! da magasin, 439, 94e Avenue, Chomedey, pour les objets suivants: Faire le commerce f 1085, Notre-Dame Street, Chomedey, and Henry Blustein.store manager.439.94th Avenue, Cho-medey, for the following purposes: To deal in clothing ami wearing apparel of all kinds, umler the name of \"Pioneer Textiles Co.\", with a total capital stock of 120,000, divided into 5,000 common shares of $1 each ami 1.500 preferred shares of $10 each.The head Office of the company will be at Chomedey, judicial «listriet of Montreal.Given at tin* oflice of the Provincial Secretary, this 9th day of July, 1002.Lucien Dabveau, Associate Assistant Secretan/ of the Province.013-o 12905-02 - 1134/114 Placements Bernier Inc.Bernier Investments Inc.F* Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 12th day of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-(i«>vernor of the Province «>f Quebec, incorporating: André Trotier, advocate, 1074, Belmont Street, Sillery, Thomas W.Brown, advocate, 1165, Belvédère Avenue, Quebec, John Boudreau, advocate, 1070.Murray Avenue.Quebec, ami Nicole Veilleux, secretary, spinster of the full age of majority, 55, Dorval, Street, Levis, for the following purposes: To act as a holding company, umler the name of \"Placement! Bernier Inc.\u2014 Bernier Investments Inc.\", with a total capital stock of $250,000, divided into 400 common shares of $100 each and 21,000 preferred shares «>f $10 each.The bead oflice of the company will be at 42, Ste-Anne Street, Quebec, jmlicial district of Quebec.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of July, 1902.Lucibn Dahvkau, Associate Assistant Secretan/ of the Province.613 12970-02 \u2014 1135/30 Les Produits Truco du Québec Ltée Truco Products of Quebec Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, beating «late the 5th day of July, 1902, have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, incor|>orating: Claude Guérin, lawyer, 32, Les Bouleaux.Laval-sur-Ie-Lac, Laurence Ostignuy, secretary, spinster of full age, 0250, 44lh Avenue, Rosemont, Montreal, and Jeanne Le Sieur, secretary, spinster of full age, 10537, Berri Street, Montreal, for the following purposes: 47KK C.AZETTE OFF 1(1 ELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 1962, Tome 9/h No SX Eisner !vince, ce fie jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dotjvillb.013 128734)2 ¦ Il 34'34 J.Propst & Son Inc.Avis «'st «lonné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur «le la province «le Québec, del lettres patentes, en «late du 18e jour «le juin 1902.constituant en corpora* tira: Jacob Propst, marchant.Mme Annie (Anna) Chartraa Propst.ménagère, épouse séparée «le Liens «ludit Jacob Propst.tOUS eleux «le 4075, rue Hutchison.Moe Propst.marchand.Mme Kileen Myers Propst, ménager»', èpOUSS séparée de biens «ludit Moe Propst.tousdeui «le 2160, rue Coyer, «'t Mme Lottie Holier, ménagère, é|M>use Séparée «le biens «le Jack Holier, 2102.rue (i«>yer, tous cinq «le M«)ntréal, pour les objets suivants: Exercer leconunercede nouveautés, vêtements et articles vestimentaires, meubles, accessoires électriques, lessiveuses, poêles, balayeuses élec- triques, réfrigérateurs électriques et tous sortes «le marchandises, articles et commodités, sous le nom «le « J.Propst & Bon inc.».avec- un capital total «le $50.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4075.rue Hutchison, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 18e jour «le juin 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dot t ville.013 12014-02 1131 129 Provost Street Development Inc.Avis est donné qu'en vertu «!«\u2022 la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 12e jour «le juin 1902, constituant en corporation: John L.Liberman.avocat, 7487, chemin Spring, (Yite-St-Luc, Albert Liddell, gérant, 3509.Hutchison, app.500, Montréal, Mina Din ia m!, secrétaire, fille majeure, 490(5, Décarie, Montréal, «'t Helen Lennon, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Rernard Damien Lennon, 1579, rue Centre.Montreal, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'entrepreneurs et constructeurs généraux, sous le nom «le « Provost Street Development Inc.».avec un capital total «le 820,000, divisé en 2.000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune et 18,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le $1 chacune.l*e siège social «le la compagnie sera 8475, boulevard Décarie, Montreal, «listriet judiciaire de Montréal.« Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 12e jour de juin 1902.Es Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivii.lk.013 12550-02\u2014 1133/27 To deal in «iiamond tools and drills and tools of all kinds, under the numc of \"Lea Produits Trued du Québec Ltée Truco Products of Quebec Ltd., with a total capital stock «>f $40.ooo, divided into 400 shares of $100 each.The head 0008 of the company will be at Montreal, judicial district «>f Montreal.Given at the office «»f the Provincial Secretary, this 5th day «>f July, 1902.Raymond Doivii.i.k, Assistant Secretary of the Province.013-o 12872-02 1134/34 J.Propst & Son Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quciuc Companies Act.letters patent, bearing date the ISth day of June, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporaUng: Jacob Propst.merchant, Mrs.Annie (Anna) (hail ran Propst.housewife, wife separate as to property e>f the said Jacob Propst.both of 4075, 1 lutein-on Street.Moe Propst.merchant, Mrs.Eileen 'Myers Propst, housewife, wife separate as to property e>f the said Moe Propst, both of 2100.Coyer Street, und Mrs.Lottie Roller, housewife, wife* sepaisle as to property e>f Jack Roher, 2102, Coyer Street, all five of Montreal, fe>r the fol- lowing purposes: To deal in dry goods, clothing and wearing apparel, furniture, electrical appliances, washing machines, stoves, vacuum cleaners, electric refrigerators ami all kinds e>f goods, wares and commodities, under the name e>f \"J.Propst & Son Inc.\".with a total capital stock of $50.000, divided into 400 common shares e>f $100 each ami 100 preferred shares of $100 each.The hea«l office of the company will be at 4075, Hutchison Street.Montreal, judicial district e>f Mont real.(liven at the office of the Provincial Secreturv, this 18th day of June, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 12*014-02\u20141131/129 Provost Street Development Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 12th day of June.1062, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: John L.Libermun, advocate, 74S7, Spring Road.(Y>te-St-Luc.Albert Liddell.manager.3509.Hutchison, apt.500.Montreal, Mina Dimaml, secretary, spinster of the full age of majority, 49(50.Décurie, Montreal, and Helen Lennon, secretary, wife separate as to property of Bernard Damien Lennon, 1579, Outre Street.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general contractors ami builders, under the name «»f \"Provost Street Development Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2.000 common shares of a par value of $1 each an«l 18,000 preferred shares of a par value of $1 each.The hcael office of the company will be at 8475, Décarie Boulevaid, Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of June, 1902.Raymond Douvili.k, Assistant Secretary of the Province.013-o 12550-02\u2014 1133/27 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September §$, 190», Vol.94, No.3S 4789 Q/uurtct Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partic «le lu Ix>i des compagnies de Québec, il a «'\u2022té acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le lu province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 22e jour «le juin 1002, constituant en corporation: Max H.Teitelbaum, 2022, rue Ward, St-Liurent, Maxwell Shenkcr, 1943, Barclay, Montreal, Daniel I.a/are, 5105, ( V)te-St-Luc, Montréal, tous trois avo«*ats, et Mlle Barbara Eliosolf, secretaire, 5555, Lyndale, Cote St-Luc, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom «le « Qirartct Investments Ltd, », avec un capital total «le $40,000, «livisé en 100 actions ordinaires «le $100 chacune t 300 actions priviélgiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 330, Alcxis-Xihon, Saint-Laurent, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 22e jour «le juin 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doc ville.618 12713-02-1133/53 R.E.S.Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accorde, pas le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 18e jour de juin 1902, constituant en corporation: Irving L.Adessky, avocat, 3782, Avenue Kent, Montréal, Lewis Batshaw, avocat, 4804, chemin «le la Côte-«lcs-Neiges, Montréal, et Shirlee Simon, secrétaire, fille majeure, 1400, Van Horne, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le restaurateurs, sous le nom de « R.E.S.Restaurant Inc.».avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions oi-ilinaires «le $10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à LaSalle, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 18e jour «le juin 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.013 12032-02\u2014 1134/30 Quartet Investments Ltd.Notice is hereby given that umler l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of June, 1902, have bean issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating! Max M.Teitelbaum, 2022, Ward Street, St-Luurent, Maxwell Shenker, 1943, Barclay, Montreal, Daniel I«azarc, 5105, Cote St-Lue, Montreal, all three advocates, and Miss Barbara Eliosoff, secretary, 5555, Lyndale, Côté St-Luc, for the following purposes: To carry on the business of un Investment Company, umler the name of \"Quartet Investments Ltd.\", with a total capital stock «>f $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred snores f $100 each.The head office of the company will be at 330, Alexis-Nihon, Saint-I^iurent, jmlicial «listriet of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd da) of June.1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 12713-02\u20141133/53 R.K.S.Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 18th day of June, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Irving L.Adessky, advocate, 3782, Kent Avenue, Montreal,' Lewis Batshaw, a«lvocate, 4804, Côte-des-Neiges Bond, Montreal, am! Shirlee Simon, secretary, fille majeure, 1400, Van Horne.Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"R.E.S.Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at LaSalle.judicial distrieto f Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of June, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.013-o 12032-02 \u2014 1134/30 Richer Jeweller Ltd.Richer Bijoutier Ltée Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a «'¦té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le lu province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 4e jour de juillet 1902, constituant en corporation: Robert Richer, bijoutier, Thérèse Spinelli, ménagère, épouse contractuellement 'séparée de biens dudit Robert Richer, tous deux de 315, rue Dumonchel, et Jean-Guy Aubry, vendeur, 10, rue Mimosa., tous trois de Dorval, pour les objets suivants: Exercer le commerça de bijoutiers, sous le nom de «r Richer Jeweller Ltd.\u2014 Richer Bijoutier Ltée », avec un capital total de $40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Dorval, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 4e jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.013-o 12855-G2- 1134/58 Richer Jeweller Ltd.Richer Bijoutier Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of July.1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Richer, jeweller, Thérèse Spinelli.housewife, wife contractually separate as to property of the said Robert Richer, both of 315.Dumouchel Street, and Jean-Guy Aubry, sidesman, 10.Mimosa Street, all three of Dorval, for the following purposes: To carry «>n business as jewellers, under the name of \"Richer Jeweller Ltd.\u2014 Richer Bijou-tier Ltée\".with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each an«l 2.000 preferretl shares of $10 each.The head office of the company will be at Dorval, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of July, 1902.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.013 12855 02 - 1134/58 4790 GAZETTE.OFF ICI ELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 11)62, Tome 94, So 88 Roca (Quebec) 1962 Ltd.Avis est (lonné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies île Québec, il a été accordé, par le lieu tenant,-gouverneur de la province de Quélx'C, des lettres patentes, en date du 28e jour de juin 1902, constituant en cor|x>ra-tion: Aliruliain Sinister, avocat, Judith Shuster, ménagère, épouse sépraée de biens dudit Abraham Shuster.et dûment autorisée par 00 dernier aux fins des présentes, tous deux de 5710.Wolscly, Côte-St-Luc, Margaret (iunstoii, Dorothy (iunston, toutesdeilZsecretaires, filles majeures.3422.Stanley, Montréal.Jay Rumunck, étudiant, 1805, Si-Germain, Saint-Laurent, et Lawrence Diner, avocat, 4080, Kingston, Montréal, pour les objets suivants: Kxcrcer un commerce de paveurs, carriers et marchands de pierre, sous le nom de « Koca (Quebec) 1902 Ltd.».avec un capital total de 810,000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.1.000 actions privilégiées, première catégorie, d'une valeur au pair de $1 chacune et S.000 aidions privilégiées, deuxième catégorie, d'une vuleur au pair de 81 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera à Lachute.district judiciaire de Terrebonne.Donné nu bureau du secrétaire de la province, ce 2Se jour de juin 1902.Le Sous-secrétaire de la proriiice.Raymond Doiviixe.013 12780-02- 1133/30 Roca (Quebec) 1962 Ltd.Notice is hereby given that umler l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of June, 1902, have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec.incor|M>rating: Abraham Shuster, advocate, Judith Sinister, housewife, wife separute as to property of the said Abraham Shuster, and duly authorised by him for the purpose of these presents, both of 5710, Wolscly.Côte-St-Luc.Margaret Gunston.Dorothy Gun-ton, both secretaries, filles majeures, of 3422, Stanley.Montreal, Jay Rumuuek.student, 1905, St.Gcrmuin, Saint-Laurent, and Luwreme Diner, advocate, 4050, Hingston, Montreal, for the following purposes: To carry on business as pavers, quarry masters and stone merchants, under the name of \"Roca (Quebec) 1002 Ltd.\".with a total capital stock of 810,000, divided into 1.000 common shares of the par value of 81 each.1.000 first preferred shares of the par value of 81 each and 8.000 second preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Lachute, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of June.1962.Raymond Doivili.k, Assistant Seen tarif of the Province.013-o 12786-62 - 1133/30 J.Puul Roy Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 13e jour de juillet 1902, constituant en corporation: Jacques Héïque, avocat, 9135, boule-var«l LaSalle, LaSalle, Céoilien Pelchat, avocat, 0405, Marseille, Montréal, et Stefania Alpern, secrétaire, veuve «le Witokl Kozlowski, 3531, Ste-Famille, Montreal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines, leurs accessoires et parties, et faire affaires comme garagistes, sous le nom «le « J.Paul Roy Inc.», avec un capital total de $40,000, «livisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 5701, boulevanl Décarte, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 13e jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire adjoint de la province, LUCIEN Dahvkau.013-o 12454-02\u2014 1135/33 J.Paul Roy Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 13th «lay of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Jacques Béïque, advocate, 9135, LaSalle Boulevard.LaSalle, Cecilien Pelchat, advocate, 0405, Marseille, Montreal, and Stefania Alpern, secretary, widow «>f Witold Kozlowski, 3531, Ste-Famille, Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles, motors, machines, their parts an«l accessories, and to act as garagemen, under the name of \"J.Paul Roy Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 5701, Décarie Boulevanl, Montreal, judicial «lis trict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of July, 1902.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary of the Province.013 \u2022 12454-02\u2014 1135/33 St.Lambert Truck Sales Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première pari ie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accoixlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 20e jour «le mars 1902, constituant en cori>o-ration: J.Clifford Savage, avocat, 314, avenue Mercille, St-Lambert, Leo Taylor, consultant en taxes, 3830, avenue Broadway, Lachine, et Leonard A.Seton, avocat et conseil en loi «le la Reine, 314, avenue Birch, St-Lambert, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'automobiles, leurs pièces et accessoires, et faire affaires comme gara- St.Lambert Truck Sales Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of March, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor qf the Province of Quebec, incorporating: J.Clifford Savage, advocate, 314, Mercille Avenue, St.Lambert, Leo Taylor, tax consultant, 8830, Broadway Avenue, Lad line, and Leonard A.Seton, advocate and Queen's Counsel, 314, Birch Avenue, St.Lambert, for the following purposes: To deal in motor vehicles, their parts ami accessories, and to carry on business as garage- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 1062, Vol.04, A'o.88 4791 gistes, sous le nom de « St.Lambert Truck Sales' Ltd.», avec un capital total de $20,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Lambert, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour d'août 1902.Le Sous-secrétaire de la province, , Raymond douville.613 11159-02 \u2014 1133/91 Super Marché Laniel Inc.Lanic! Super Market Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie de la \\a>\\ «les compagnies «le Quéliec, il a été acconlé.par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 0e jour «le juillet 1902, constituant en Corporation: .lean-Louis Laniel.épicier, 5113.rue Marquette, Jacques Laniel.épicier, 5730, 7e Avenue.Kosemont, et Pierrette Jean, secrétaire, 0205, 2e Avenue.Rosemont.tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Paiie le commerce d épicerie, SOUS le nom «le « Super Mar«-hé Laniel Inc.Laniel Super Market Inc.».avec un capital total de $40.000, «livisé en 1.500 actions ordinaires «l'une valeur nominale «le $10 chacune «'t en 2.500 actions privilégiées «l'une valeur nominale «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 1051, rue Laurier, est.Montreal, district judiciaire de Montreal.Donné au bureau du Secrétaire de la province, «\u2022e (k* jour de juillet 1902.Le Sous-secrétaire de la provitice, Raymond Douville.613-0 1241S-02 - 1134/93 keepers, umler the name of \"St.Lamlicrt Truck Sales Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 100 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at St.Lambert, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of August, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.613-0 11159-02 \u2014 1133/91 Super Marché Laniel Inc.Laniel Super Market Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 6th day of July, 1002, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Louis Laniel, grocer, 5113.Marquette Street, Jacques Laniel, grocer.5730.7th Avenue, Rosemount, and Pierrette Jean, secretary, 0205.2nd Avenue, Rosemount, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the nume of \"Super Marché Laniel Inc.\u2014 Laniel Super Market Inc.\".with a total capital stock «»f $40,000.divided into 1,500 eonsmon shares «>f a nominal value of $10 each and 2.500 preferred shares of a nominal value «>f $10 each.The head office «»f the company will be at 1661, Laurier Street.East.Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this oth day of July, 1963.Raymond Dot;ville.Assistant Secretary of the Province.013 12418-02 1134/93 La Taverne Des Pin» Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-g«>uvcrneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 20e jour de juin 1902.constituant en corporation: Murray Lapin, avocat, 107, chemin Edge-hill, Westmount.Harold Dernier, avocat, 4957, avenue Borde, Montréal, et Shriley Muggeridge, secrétaire, fille majeure, 59, rue Orchard, LaSalle, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le tavernes, brasseries et /ou restaurants, sous le nom de « La Taverne Des Pins Inc.», avec un capital total de $1,000, divisé en 1,000 actions «l'une valeur au pair «le $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 3714, avenue «lu Parc, Montréal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de juin 1902.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville.013 12078-02\u2014 1133/107 Textile Values Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 9e jour de juillet 1962, constituant en corporation: Ezra Leithman, cit., Fred Kaufman et Sidney Leithman, tous trois avocats, 1255, rue Phillips, Montréal, pour les objets suivants: La Taverne Des Pin» Inc.Notice il hereby given that umler Part I of the Quebec Ctunpanies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of June, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Murray Lapin, advocate, 107.E«lgehill Road.Westmount, Harold Dernier, advocate, 4957, Borden Avenue, Montreal, and Shirley Muggeridge.secretary, spinster of the full age of majority, 59.Orchard Street, l^aSalle, for the following purposes: To carry on the business of o|h-rating taverns, public houses and/or restaurants, under the name of \"La Taverne Des Pins Inc.\", with a total capital stock of $1.000.divided into 1.000 shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at 3714, Park Avenue, Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of June.1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.613-0 12078-02\u2014 1133/107 Textile Values Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 9th «lay of July, 1902, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Ezra Leithman, q.c, Fred Kaufman and Sidney Leithman, ail three advocates, of 1255, Phillips Street, Montreal, for the following purposes: 4792 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 190$, Tome !>/,, So SS Exercer le commerce «le vêtements et d'articles vestimentaires, sous le nom n business as restaurateurs, umler the name of \"(Jump Worsley's Century 21 Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each ami 3,900 preferred shares of $10 each.The bead office of the company will be at 353, Dorval Avenue, Dorval, judicial distirct oi Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary .this 5th day of July, 1902.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.013-o 12853-62\u2014 1135/109 Actions for separation as to property Got«'\u2022 vs Chabot Province de Québec, «listriet de Bedford, Cour Supérieure No 11,770.Dame Gertrude Côté épouse de Orner Chabot, artisan «le la cité de Granby, district «le Bedford, a formé contre son mari une demande en séparation de biens.Sweetsburg, le 10 septembre 1902.Le Procureur de la demanderesse, 034-o Geo.-H.Duhkault, en.Latizia rs Ferland Province de Québec, «listriet de Montréal, ('our Supérieure.'No 581-074.Dame Palasciano Latizia, épouse de Gabriel Ferlant!, investigateur, «le la cité et district de Montréal, a institué une action en séparation de biens.Montréal, le 13 septembre, 1902.Le Procureur de la demanderesse, John Hekschohn.1396, ouest, rue Ste.Catherine, Montréal, Que.635-o Côté rs Chabot Province of Quebec, district of Bedford, No.11,776; Dame Gertrude Côté, wife of Orner Chabot, of the city of Granby, «listriet of Bedford, has instituted against her husband, an action in separation as to property.Sweetsburg, September 10, 1902.Geo.-H.Dureault, q.c, 034-o Attorney for Plaintiff.Latizia vs Ferland Province of Quebec, district of Montreal.Superior Court, No.581-074, Dame Palasciano Latizia, wife of Gabriel Ferlaml, investigator, of the city and district of Montreal, has institute* 1 an action in separation as to property.Montreal, September 13, 1902.John Herhchorn, Attorney,for Plaintiff.1390, St.Catherine Street, West, Montreal, Que.635- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 199», Vol.94, So.3S 4793 Arrêtés en Conseil Arrêté en conseil diamine du Conseil Exécutif Numéro 1490 Section « A » QuftlOdi le 12 septembre I960.Présent: I,e lieutenant-gouverneur en conseil.('oncehn ant lies modifications un décret relatif aux employés e amended as follows: 1.Paragraphs \"a\" and \"«7' of article III are replaced by the following: \"III.Wages: a) In the case of employment by the week, the minimum wages shall be as fol- \u2022 lows: Per week Barman.$57.00 Assistant barman.47.00 Waiter.4100 Apprent ice or beginner.34.00 Should an assistant barman work as barman dining forty (40) hours or more in the course of a same work week, the minimum wages of such employee shall be increased by three ($3.00) per week.b) In cases of employment by the hour, the wages for fifty (50) hours of work per week at the rates hereunder mentioned are guaranteed anil shall be pai«l to regular employees of any one category, even if such employees work less than fifty (50) hours during the week: Per hour Barman.$1.10 Assistant barman.0.95 Waiter.0.84 Apprent ice or beginner.0.72\" 2.Section IV is replaced by the following: .\"IV.Duration of work: The standard work week consists of fifty-two (52) hours which shall be distributed at the employer's will and every employee working more than fifty-two (52) hours per week is entitled to the rate of time and one half.Employees are entitled to one hour and a half (11 i for the noon meal and to one hour and a half (l'i) for the evening meal.Also, no employer may oblige his employee to work 4794 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 1062, Tome Oh.No 3H à travailler plus «le eimpiante-dcux (52) heures par semuine.» 3° Le paragraphe intitulé « Age » apparaissant à l'article VI est remplacé par le suivant: « Age: Aucun salarié assujetti au présent décret ne doit être âgé de moins de 20 ans.» 4° L'article VIA est remplacé par le suivant: « VI-A.Jours fériés: Le Premier jour de l'An.l'Epiphanie, le Mercredi des ( lend res, le Vendredi* Saint, l'Ascension, lu Toussaint, l'Immaculée Conception et le jour de Noël doivent être chômés et payés au même taux «prune journée normale «le travail suivant le salaire payé à l'employé et en tcnani compte de sa fonction régulière «le travail, à moins «pie ces fêtes ne tombent le dimanche alors qu'eues ne sont pas payées.Cependant si les salariés sont appelés au travail par leur employeur, l'un ou l'autre «le ces jours de fêtes, ils auront droit à une rémuuéiatioii minimum égale à cinq (ô) heures «le travail au taux régulier en urgent suivant l«-s fonctions qu'ils occupent indépendamment de lu durée de leur servi«-e.À compter «le cinq (f>) heures «le travail, les salariés doivent être rémunérés en aigcnt au taux régulier suivant les fonctions qu'ils occupent en proportion «les heures travaillées, et «\u2022«\u2022.au taux mentionné au paragraphe « b » de l'article III.Les jours d\" votât ions dans la circonscription électorale où se tient une élection fédérale, provinciale ou municipale, sont «les jours fériés et doivent être rémunérés suivant le mode ci-haut prévu pour les jours «le fêtes.Cependant, à compter de l'heure où la loi permet à l'employeur «l'ouvrir son établissement, il peut requérir les services «le ses employés jusque l'heure ral «listriet in which a Federal, Provincial or Municipal election is being held, arc holidays and shall be remunerated in the manner provided hereinabove for feast \u2022lays.However, from the moment at which the law allows the employer to open his establish ment, he may require the services of his employees until his regular closing hour, without additional remuneration.\" 5.Paragraph \"b\" of article VII is replaced by the following: *'b) Period of continuous service which gin-right to aforesaid racation: For each annual or additional vacation with pay, the perùxl r such employer, shall lu- entitled, f«>r his vacation.t«> the 4% remuneration provided for in the preceding paragraph; but the remuneration of such employee shall not be less than two weeks1 wages reckoned on the basis of forty (40) hours per week at the minimum rate for his class.\" 5.Article 37 is replaced by the following; \"Section 37: Duration of the decree: The present decree remains in force until March 31, 1905.It then renews itself automatically from year t«> year, unless one of the contracting parties notifies the other party, in writing, to the contrary between ()«-tober 1 and November 30, 1904 or between October 1 and November 30 of any subsequent year.Such a notice shall also be given to the Minister of Labour.\" Section 2: 6.In paragraph \"j/\" of section 2.the words \"wrought or moulded rubber heels\" shall be replaced by the words \"wrought or moulded heels\".Section 4: 7.Percentage of apprentices.In the last line of the first paragraph of section 4, the number 529-5 shall be replace»! by 529-4.Section 7: 8.Paragraph \"/\" of section 7 shall be deleted.Section 12: 9.The following words .shall he adde«l to operation 227-3: - \"Stapling heel to insole\".10.Opera!i«>n 234-4 shall read: - \"234-4 - Roughing, polishing, staining, setting heel or loose sole or heel fix«-«l to loose sole, on automatic or otherwise.- Polishing insole shank.\" Section 13: 11.Operation 300-2 shall read: - \"300-2- Moulding counter in upper.- Premoukling counter on O.M.I.t '.Machine.\" 12.Operation 330-4 shall read: - \"330-4 - Steaming upper of slipper.-Cutting lining surplus before fixing fur ami collar.\" 13.Operation 331-5 shall be added: - \"331-5 - Combing fur.\" 14.Operation 332-4 shall read: - \"332-4 - Trimming upper after lasting.-Cutting lasting allowance at counter tip (Stitclulown).\" - Section 14: 15.Operation 404-3-The following words shall be a«l«le«l to operation 404-3: - \"Stapling loose sole am! heel with stapling machine or with Auto Soler.\" 10.The first sentence of operation 404-3 shall rearming boxes by imiehinc\" is a class A operation.\" 21.Operation 532-1 shall be added: - \"532-1 - Machinist-millwright who assembles, disassembles ami repairs machines.\" 22.Operation 533-3 shall be added: - \"533-3 - Maintenance millwright doing upkeep of machines.\" Section 16: 23.The following words shall be added at the bottom of the rates, after the wor«ls \"Initiation Period\": -\"The initiation period applies only to employons who have never worked in the Shoe Industry.\" Section 17: 24.Operation 600-A - The word \"scoring\" shall be added to operation 000-A, after the word \"skiving\".The second sentence of operation 600-A shall read: - \"Without limiting the generality of its terms, Class A applies in particular to the following operations: skiving, scoring, perforating, etc.\" 25.Operation 600-A-The words \"pleating upper\" shall be added at the eml of operation 600-A.Section 20: 20.The first sentence of the last but one para graph of section 20, French text, shall read: - \"Lorsqu'un employé est engagé dans une fabrique «le chaussures, il doit.etc.\" 27.The last paragraph of section 20, beginning by the words \"Where the minimum rate .\" shall be our 1903: «lu 7 au 20 juillet; pour 1904: du 12 au 25 juillet.» 32° Ia: paragraphe «/ » «le l'article 24 est remplacé par le suivant: « Les deux semaines de vacances mentionnées plus haut doivent être chômées.Tout employeur ipii, sans autorisation préalable du Comité, fait travailler «les salariés à la production de la chaussure, que ces salari«'\\s aient été préalablement ses mployés ou n«>n, pou lai il ces deux semaines ou une partie quelconque «le vvs «leux semaines, «loit payer salaire double, (>n plus du montant qui peut être re«;u pour vacances.» Article 27: 33° L'articlc 27 est ra«lié.Article 29: 34° ïm dernière phrase «le l'article 29, commen-çant par les nuits « Aucun employeur n'a le droit \u2022 \u2022 \u2022 » est biffée.Article 30: 35° L'article 30 est ra«lié.Irticle 31: Lieu de travail.30° Le «leuxième paragraphe «le l'article 31 «loit se lire comme suit : « Toutefois, l'employeur peut «lonnerdu travail à domicile, selon «les conditions déterminées, au préalable, par le comité paritaire.» Article 31-A: couture à la main des spécialités indiennes.37° La liste «le prix apparaissant à l'article 31A doit se lire comme suit: Section 24' Paragraph \"a\".31.The last sentence of paragraph \"a\" of section 24 shall be cancelled ami replaced by the billowing one: \"The vacation period shall l>e: for 1903: from the 7th to the 20th of July, for 1904; from the 12th t«> the 25th «>f July.\" 32.Paragraph \"/\" «jf section 24 shall lie replace»! by the following one: \"No work must be «loue during the two vacation weeks mentioned above.Any employer who, without previous authorisation of the Committee, makes uny employee \\v«>rk at the shoe production, whether these wage earners had been previously his employees or not, during these two weeks or any part thereof, shall pay double time, plus the amount I hat might be «lue for vacation.\" Section 27: 33.Section 27 shall be deleted.Section 29: 34.The last sentence of section 29, beginning by the words \"No employer shall have .\" shall Ik; deleted.Section 30: 35.Section 30 shall be «leleted.Section 31: Working places.30.The second paragraph of section 31 shall read as follows: \"However, employers may give out work to l>e done at home, under conditions «letermined, in advance, by the Joint Committee.\" Section 31 A: sewing by hand of indian specialties.37.The price list appearing in section 31A shall read as follows: Liste de prix, couture à la main \u2014 Price list for ham! sewing Prix du 100 paires \u2014 Price for 100 pairs Du 1er septembre 1902 au 31 août 1903 \u2014 From September 1, 1902 to August 31, 1903 Sorte de cuir \u2014 Kind of leather Baudrier Vache cuir très dur Point-croisé travaillé mouillé Huile Chrome Oper.Hommes-Men No.Pointures : G à 12 \u2014 Sizes : 6 to 12 1.Montage (mettre soulier sur forme et ajuster \u2014 Lasting.Coudre \u2014 Sewbig 2.Tablier (dessus) \u2014 Vamp.3.Montée \u2014 Vertical stitch.4.Travers \u2014 Horizontal.5.Démontage \u2014 Unlasting.t )|>er.Femmes \u2014 Women No.Pointures : 3 à 9 \u2014 Sizes : 3 to 9 0.Montage \u2014 Lasting.Coudre \u2014 Sewing 7.Tablier \u2014 Vamp.8.MonJ.ee \u2014 Vertical stitch.9.Travers \u2014 Horizontal.10.Démontage \u2014 Unlasting.Cow Hide Cross Stitch A Bend: Very hard leather dressed and wet B Oil Tan Chromium C D $ 5.30\t$ 8.12\t$ 8.12\t$ 8.12 37.54 5.30 5.30 3.04\t42.91 8.12 9.30 3.04\t40.19 0.08 8.12 3.04\t34.83 6.08 0.08 3.64 $57.20\t$72.15\t$00.75\t$59.95 S 5.30\t$8.12\t$ 8.12\t$ 8.12 34.83 3.95 3.95 3.04\t40.19 8.12 9.30 3.64\t37.54 0.08 8.12 3.64\t32.28 6.68 6.68 3.04 151.73\t$09.43\t$04.10\t$57.40 4800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre 199», Tome .94.\\o 3s Liste «le prix, couture à la main \u2014 Priée list for anhd.sewing Prix du 100 paires \u2014 Priée for 100 pairs Du 1er septembre 1902 au 31 août 1903 \u2014 From September 1, 1902 to August 31, 1903 Borifl «le cuir \u2014 King of leather Baudrier Vache cuir très dur Huile Chrome Point-croisé travaillé mouillé Cow Hide Cross Stitch 0|h>r.( îarçons \u2014 Boys No.Pointures: 1 à 5 \u2014 Sizes: 1 to 5 A 11.Montage \u2014 listing.Couture \u2014 Sewing 12.Tablier \u2014 Vamp.13.Montée \u2014 Vertical stitch.14.Travers \u2014 H«»rizontal.15.Démontage \u2014 Unlasting.0|ht.Filles \u2014 Cirls No.Pointures : 11 à 2 \u2014 Sizes : 11 to 2 10.M«>ntage \u2014 Lasting.$3.95 Couture \u2014 Sewing 17.Tablier\u2014 Vamp.33.91 18.Montée \u2014 Vertical stitch.2.94 19.Travers \u2014 Horizontal.2.94 20.Démontage \u2014 Unlasting.2.85 $40.59 Ol>er.Enfants \u2014 Chihlren No.Pointures: 4 à 10 \u2014 Sizes: 4 to 10 21.Montage \u2014 Lasting.$ 3 95 Couture \u2014 Sewing 22.Tablier \u2014Vamp.28.50 23.Montée \u2014 Vertical stitch.2.42 24.Travers \u2014 Horizontal.2.85 25.Démontage \u2014 Unlasting.2.85 $40.57 Bend: Very hard leather dressed and wet B $ 8.12 37.54 0.08 8.12 3.04 Oil Tan Chromium C $ 8.12 34 83 5 30 6.68 3 04 D $ S.12 28.24 5.30 0.68 3 61 $64\t10\tS5N\t03\t$52 04 $ 8\t.12\t$ 8\t12\t$ 8.12 33\t.91\t28\t24\t24 25 5\t.30\t5\t30\t3.95 6\t.08\t0\t08\t5.30 3\t04\t3\t04\t3 04 $57\t71\t$52\t04\t$45 32 $ 8\t12\t$ 8.\t12\t$ 8.12 30\t88\t25\t47\t21.52 5\t30\t5\t30\t3 95 6\t68\t0\t08\t5.30 3\t64\t3\t04\t3.04 $54.08 $49 27 $42.59 Du 1er septembre 1963 au 30 juin 1904 \u2014 From September 1, 1903 to June 30, 19G4 Oner.Hommes \u2014 Men No.Pointures : 0 à 12 \u2014 Sizes : 0 to 12 1.Montage (mettre soulier sur forme et ajuster) \u2014 Lasting.Comlre \u2014Sewing 2.Tablier («lessus) \u2014 Vamp.3.Montée \u2014 Vertical stitch.4.Travers \u2014 Horizontal.5.Démontage \u2014 Unlasting.Oper.Femmes \u2014 Women No.Pointures : 3 à 9 \u2014 Sizes : 3 to 9 0.Montage \u2014 Lasting.Coudre \u2014 Sewing 7.Tablier \u2014 Vamp.8.Montée \u2014 Vertical stitch.9.Travers \u2014 Horizontal.10.Démontage \u2014 Unlasting.Oper.Gseoons \u2014 Boys No.Pointures : 1 to 5 \u2014 Sizes : 1 to 5 11.Montage \u2014 Lasting.Couture \u2014 Sewing 12.Tablier\u2014 Vamp.13.Montée \u2014 Vertical stitch.14.Travers \u2014 Horizontal.15.Démontage \u2014 Unlasting.$ 5.04\t$ 8.54\t$ 8.54\t$ 8.54 39.49 5.04 5.04 3.83\t45.13 8.54 9.85 3.83\t42.27 7.03 8.54 3.83\t30.04 7.03 7.03 3 83 $00.24\t$75.89\t$70.21\t$03.07 $ 5.04\t$ 8.54\t$ 8.54\t$ 8.54 36.04 4.15 4.15 3.83\t42.27 8.54 9.85-3.83\t39.49 7.03 8.54 3.83\t33.95 7.03 7.03 3.83 $54.41\t$73.03\t$07.43\t$00.38 $ 8.54\t$ 8/54\t$ 8.54 39.49\t30.64\t29.70 7.03\t5 64\t5.04 8.54 \u2022\t7.03\t7.03 3.83\t3 83\t3 83 $07.43\t$01.08\t$54.74 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September 22.11)62.l'ai.H.',, So.3H 4801 Liste ilv prix, «ont uro à lu nui in Price list for liai m I sewing Prix dll 100 pairs Price for 100 puirs Du 1er septembre 1088 au 80 juin 1901 \u2014 From September I, 1988 to June 80, 1904 ' )per No.17.18.19.20.Filles-Cirls Pointurse: 11 » 2 \u2014 Sizes: 11 to 2 Montage \u2014 Lest ing.\u2022.Couture \u2014 Sewing Tablier \u2014 Yamp.Montée \u2014 Vertical stitch.Travers \u2014 Horizontal.Démontuge \u2014 Unlasting.I toer.Ki i bint s \u2014 ( 'hildren No.Pointures: 4 à 10 \u2014 Sizes: 4 to 10 21.Montage \u2014 lasting.Couture \u2014 Sewing 22.Tablier \u2014 Vamp.23.Montée \u2014 Vertical stitch.24.Travers \u2014 Horizontal.25.Démontage \u2014 Unlasting.Du 1er juillet 1904 au 31 mars 1905 « hier.Hommes \u2014 Men No.Pointures: G à 12 \u2014 Sizes: 0 to 12 1.Montage (mettre soulier sur forme et ajuster) \u2014 Lasting.Coudre \u2014 Sewing 2.Tablier (dessus) \u2014 Vamp.3.Montée \u2014 Vertical stitch.4.Travers \u2014 Horizontal.5.Démontage \u2014 Unlasting.« hier.Femmes \u2014 Women No.Pointures : 3 à 9 \u2014 Sizes : 3 to 9 G.Montage \u2014 Lasting.Coudre \u2014 Sewing 7.Tablier \u2014 Vamp.8.Montée \u2014 Vertical stitch.9.Travers \u2014 Horizontal.10.Démontage \u2014 Unlasting.Du 1er juillet 1904 au 31 mars 1905 i Iper.(iarçons \u2014 Boys No.Pointures: 1 à 5 \u2014 Sizes: 1 to 5 11.Montage \u2014 Lasting.Couture \u2014 Sewing 12.Tablier \u2014 Vamp.13.Montée \u2014 Vertical stitch.14.Travers \u2014 Horizontal.15.Démontage \u2014 Unlasting.I )per.Filles \u2014 Oirls No.Pointures: 11 à 2 \u2014 Sizes: 11 to 2 1 G.Montage \u2014 Lasting.Couture \u2014 Sewing 17.Tablier \u2014 Vamp-.18.Montée \u2014 Vertical stitch.19.Travers \u2014 Horizontal.20.Démontage \u2014 Unlasting.Sorte de cuir \u2014\t\tKind of leather\t l'aehe IWint-croisê\tlioudrier cuir très dur traraillé mouillé\tl/uile\t( 'hrome Cote hide Cross stitch A\tlieiid: l'en/ hard leather dressed and wet B\tOU Tan C\tChromium D $ 4.15\t$ 8.54\t$ K.54\t6 S.54 35.67 3.09 3 09 3 00\t35.07 5.04 7.03 3.83\t29.70 5.04 7.03 8.88\t25.51 4.15 5.64 3.83 $49 00\t860.71\t$54.74\t$47.67 $ 4.15\t$ 8.64\t$ 8 54\t$ 8.54 29.98 2 54 3.00 3.00\t32.48 5 64 7 03 3 83\t26 79 5 04 7.03 3.83\t22.64 4 15 5.64 3.83 $42.67\t$75.52\t$51.83\t$44 80 \u2014 From July 1.1964 to March 31.1905\t\t\t $ 5.99\t$ 9.07\t$ 9.07\t$ 9.07 41.93 5.99 5.99 4.00\t47.91 9 07 10.40 4.00\t44.88 7.46 9.07 4 00\t38.90 7.46 7.46 4.06 $03.90\t$80.57\t$74 54\t866.95 $ 5.99\t$ 9.07\t$ 9.07\t$ 9.07 38.90 4.41 4.41 4.0G\t44.88 9.07 10.46 4.00\t41.93 7.40 9.07 4.06\t36.05 7.46 7.46 4.00 $57.77\t$77.54\t$71.59\t$04.10 \u2014 From July 1, 1964 to March 31, 1905\t\t\t \t$ 9.07\t$ 9.07\t$ 9.07 >\t41.93 7.40 9.07 4.00\t38.90 5.99 7.40 4.00\t31.53 5.99 7.46 4.00 \t871.59\t$05.48\t$58.11 $ 4.41\t$ 9.07\t$ 9.07\t$ 9.07 37.87 3.28 3.28 3.18\t38.87 5.99 7.40 4.00\t31.53 5.99 7.46 4.00\t27.08 4.41 5.99 4.00 $52.02\t$04.45\t$58.11\t$50.01 4S02 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, $$ septembre 186$, Tome 94, So 38 Liste «h* prix, Couture à lu main Price list for hand sewing Prix du 100 paires\u20141 Price for 100 pairs Du 1er juillet 1904 un 81 mars 1905 \u2014 From July 1, 1904 to March 81, 1905 Oper.Enfants - - Children No.Pointures: 4 à 10 \u2014 Sizes: 4 to 10 21.Montage\u2014 lasting.Couture \u2014 Sewing 22.Tahlicr \u2014 Vamp.23.Montée\u2014Vertical stitch.24.Travers - Horizontal.25.Démontage\u2014 In lasting.Article 32A: 38° L'article 32A est ajouté.« Article 32A - Evaluation des tâches.» « Le comité engagera une maison d'ingénieurs pour faire l'évaluation de toutes les tâches de l'industrie de la chaussure et déterminer le pointage de chacune de ces tâches.Advenant le cas où le comité paritaire ne s'entendrait pas sur le choix de la maison d'ingénieurs, le conciliateur du ministère du travail, reconnu par les parties aux présentes négociations, décidera de ce choix.Si ce dernier est dans l'incapacité physique d'agir, le Ministre du Travail nommera un substitut.» Article S6A: 39° Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de l'article 3GA: « Dans un délai maximum de six mois suivant la conclusion des présentes négociations, les parties étudieront la politique de négociations.Cette question se rapporte à l'article 30A du décret et au document soumis par la partie syndicale, le 13 juillet 1900, intitulé: « Convention collective intervenue en vertu de la loi des syndicats professionnels, Statuts refondus de Québec 1941 ».Si, à la suite de cette étude, il n'y a pas entente, la question sera référée à un arbitre qui sera désigné par les parties; au cas de mésentente sur le choix de l'arbitre, ce dernier sera désigné par le Ministre du Travail.40° Le deuxième paragraphe «le l'article 30A commençant par les mots « Privilèges de modifier les zones .» est biffé.Jacqiks Premont, 039-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Sorte «le cuir \u2014\t\tKiml f section 3GA, beginning with the words \"Privilege of amending zones .\" is deleted.Jacqieh Prémont, 039-o Associate Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1490 Section « C » Québec, le 12 septembre 19G2.Present: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification à tous les décrets régissant l'industrie et les métiers de la Construction dans la province.Order in Council Executive Council Cham lier Number 1490 Section \"C\" Quebec, September 12, 19G2.Present: The Lieutenant-Covernor in Council.Concerning an amendment to all decrees governing the construction industry and trades in the Province. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September $$, 186$, Pel.94, So.88 4803 Re: Industrie des Ascenseur» Attendu qik, conformément aux dispositions de lu Ix>i «le lu convention collective (Statuts refondue de Québec 1041, chapitre 168 et amen* dements), la Ministre du Travail a donné avis de SOU intention de soumettre à l'appréciation ei à la'décision «lu lieutenant -gouverneur en conseil une modification ù l'arrêté en conseil numéro 648(B) «lu 26 juin 1957 «'t amendements, établissant les salaires minima des ouvriers travaillant pout l'industrie «les ascenseurs et .(iiicernant tous les décrets naissant l'industrie el les met ici s «le la Construction dans lu pro- \\ ince; Attendu qui l«'«lit avis a été publié dans lu GateUe officielle de Québec, édition «lu 7 juillet 1062; Attendu Qu'aucune objection n'a «'-té formulée «outre la modification proposée, Ii.kst oiiiioxnk, en conséquence! sur la proposition «le l'honorulilc Ministre du Travail: 1° Que ledit arrêté en conseil, numéro 648(B), M>it modifie comme suit: Les taux de salaires pour la région de Montréal, sont remplacés par les suivants: « Région de Montréul: Mécanicien Aide comprenant tout le territoire situé entre la région de Hull et la région de Quenec.83.38 82.37» 2° Que le décret numéro «il3 du 6 avril 1902 el amendements, realtif à l'industrie et aux métiers «le lu Construction dans la région de Montréal, soit modifié comme suit: Dans la section « II », l'article IX est remplacé pur le suivant: « IX.Taux de salaires: Les taux minima «le salaires sont les suivants: TttUX horaire Mécanicien.83.38 Aide.2.37» Jacques Prémont, 639*0 Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Kxéeutif Numéro 2424 Québec, le 14 décembre 1961.Présent: Le licutemuit-g«»uverneur en conseil.Concernant la vitesse permise sur les chemins entretenus par lu province (S.R.Q.1941, chapitre 142 et ses ameiulements, (article 41 \u2014 paragraphe 1-E).Attendu que l'article 68'«lu Code «le la route (R.S.Q., 1941, chapitre 142 et amendements) autorise le lieu tenant-gouverneur en conseil ù faire tout règlement qu'il juge nécessaire à la mise à exécution de cette loi; Attendu qui le sous-paragraphe « c » du paragraphe « 1 » de l'article 41 interdit une vitesse excédant trente milles à l'heure dans les cités, villes et villages, sauf sur les chemins entretenus par la Province et sur lesquels l'autorité provinciale compétente a placé «les paneaux indicateurs «le la vitesse permise; Attendu qu'il a y a lieu de «léterminer quelle est l'autorité provinciale compétente à ces fins.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Ministre des transports et communications: He: Elevator Industry Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (R.S.Q.1941, chapter 163 and amendments), the Minister of Labour has given notice of his intention to submit to the consideration and dacisian of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to Order in Council number 643(11) of June 26, 1957 and amendments, establishing minimum wage rates for employees working in the Elevator imlustry and concerning nil the construction imlustry and trades decrees in the province! Whereas the said notice has been published in the Quebec Official Gazette, issue of July 7, 1962; Wiikukas no objection has been raised aguinst the pn.pos.rd amendment; It is oudkukii.therefore, upon the recomraen-dat ion of the Honourable the Minister of Lul>our: 1.That the said order in council, number 643(B), be amended us follows: The rates of wages for the region of Montreal, are replaced by the following: \"Montreal region: Mechanic Helper including the entire territory lying between the Hull re- gion and the Quebec region S 3.38 82.37\" 2.That the decree number 613 of April 6, 1962 and umemlments, relating to the construction imlustry and trades in the regain «»f Montreal, be a in ended as follows: In section \"H\", article IX is replaced by the following: \"IX.liâtes of wages: The minimum rates of «rages shall be as follow: Hourly rates Mechanic.83.38 Helper.2.37\" Jacques Prémont, 639-o Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 2424 Quebec, December 14, 1961.Present : The Lieutenant-Governor in Council.Concerning, speed allowed on the roads maintained by the Province (R.S.Q.1941, chapter 142 ami its amendments (section 41 \u2014 paragraph 1-E).Wiikheas section 68 of the Road Code (R.S.Q., 1941, chapter 142 and amendments) authorizes the Lieutenant-Governor in Council to make any regulation that he deems necessary in the execution of this Act; Wheheas sub-paragraph \"e\" of paragraph \"1\" of section 41 forbids speed exceeding thirty mill's an hour in cities, towns ami villages, except on roads maintained by the Province and on which competent provincial authority has placed posters indicating the amount of speed allowed; Wiieueas it is deemed expedient to determine which provincial authority is competent for such purposes.It is therefore ordained, upon the proposition of the Minister of Transportation and Communications: 4804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 septembre 11162, Tome U/t, So 8S Que le ministère de lu voirie suit désigné l'autorité compétente aux tins «le fixer la vitesse permise sur les chemins eut retenus par la Province et d'y placer des panneaux indicateurs «le cette vitesse.L.I) ksi lets, 648-«» Greffier du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil l'han l»re du Conseil Kxécutif Numéro 1490 Québec, le 12 septembre 1902.Present: Ia.' lieutenant-gouverneur «'il conseil.( 'onckknant certains actes u«hninistratifs du ministère «les affaires culturelles.Il est ORDONNÉ, sur la proposition du Ministre «les affaires «\u2022ulturelles: Que l'arrêté en conseil numéro 40 en «late du 14 janvier 1900, soit abrogé et remplacé par le présent arrêté; Que les règlements annexés à la proposition sur laquelle est lmsé le présent arrêté en conseil, «le l'Académie de Musique de Québec, ayant trait aux concours «lu Prix «l'Europe, tels qu'adoptés le 12 juin 1902, entrent en vigueur et aient force «le loi à compter du 30 septembre 1902, et qu'ils soient publiés «lans la Gazette officielle de Québec, le tout conformément aux dispositions de l'article 2 «le la Loi «le l'art musical, (statuts refomlus «le Québec, 1941, chapitre 00), tel que remplacé par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi «le l'art musical (Bill numéro 1G), sanctionnée le 18 décembre 1959.Jacques Pkémont, Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Règlements de l'Académie de Musique de Québec concbbnant les concours du Prix d'Europe 1° Organ isatwn des concours: L'Académie «le Musique «le Québec organise chaque année deux concours afin «l'attribuer «leux bourses désignées sous le nom de Prix «l'Europe.2° Date et lieu des concours: Ces concours annuels sont tenus à Québec et à Montréal, dans le courant «lu mois «le juin.3° Sections des concours: Ia>s concours se divisent en «leux sections: Première section a) Classe «le chant; b) ( 'lasse d'instruments ù clavier: piano, orgue, clavecin.Deuxième section a) Classe d'instruments d'orchestre: violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, harpe et instruments «le percussion.b) Classe de composition.4° Cycle des concours: Les concours alternent suivant le cycle ci-après décrit: Première année: Le concours pour la classe d'instruments d'orchestre est tenu à Montréal, tandis que celui pour la classe de composition a lieu à Québec.Deuxième année: Le concours pour la classe de chant a lieu à Québec et le concours pour la classe d'instrument à clavier a lieu à Montréal.That the Department of Roads be designate'! as the competent authority for purposes of fixing the speed allowed ou roadl maintained by tin Province ami to place thereon posters indicating such speed.L.Dksilkts, 048 Clerk of the Executive Council.Order in Council Kxecutive Council Chamber Number 1490 Quebec, September 12, 1902.Present: The Lieutenant-Governor in Council CONCERNING certain administrative acts of tin Department of Cultural Affairs.It is ordained, upon the proposition of tin Minister of < u It ma I Affairs: That the Order in Council number 40 dated January 14, 1901), he rescinded ami replaced by the present or«ler-in-council; That the by-laws annexed to the pioposition on which the present «>r«ler-in-council of tin Quebec Academy of Music is based, in connection with the \"Prix «l'Europe\", as adopted on June 12.1902, comes into force as an act from and after September 30, 1902, ami that it be published in the Quebec Official Gazette, the whole in accordance with the provisions t)f section li of the Music Encouragement Act.(Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 06) as replaced by section 1 of the act amemiing tin-Music Encouiagement Act (bill number 16).sanctioned on December 18, 1959.Jacques Prémont, Associate Clerk of the Executive Council.bv laws «)f the quebec academy of mush respecting contests for the \"Prix d'Europe\" 1.Organization ercussion instruments.b) Composition.4.Cycle for contests: The contests shall alternate according to the cycle hereafter described: First year: contest for orchestral instruments is held in Montreal, whereas that for composition takes place in Quebec.Second year: Contests for vocal music takes place in Quebec and contest for keyboard instruments takes place in Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September's22.HW.Vol.!!.',, So.Ss 4K0\"> Troisième année: Ia' concours POUF i> «'lasse /'instruments d'orchestré est tenu à Québec et le .«uH'ours pour la classe de comfHtsition à Montréal.Quatrième année: Le concours pour la classe ¦le «-liant a lieu ù Montréal, tundis «pic le concours poUf la classe d'instruments à clavier a lieu ù Québec.I.i-s concours débutent en juin I903 par les classes participate in the contests; c) A swem «leclaration attesting that he \"a a Canadian citizen and that he has resided in the Province «»f Quebec for tin- last three years, 10.Additional documents required: a) Between April 1 and April 15 «>f the year \"f the contest, the candida le .shall provide a «'«impiété list of the music teachers, private as well as group teachers, umler whom lie has studied during the last four years.//) On «>r before the «late «>f the COAtest, the candidate shall provide a certificate establishing the fact that he hohls a \"Lauréat\" «liploma from the Quebec Academy «>f Music, f Music and of Dramatic Art of the Province «>f Quebec in the branch he intends to enter i'» the contest, 11.Registration for more than one instrument in contests: A competitor may register for more than one instrument, but only one sclmlarsliip may be allotted to him.12.Jury: The Quebec Aca«lemy of Music shall appoint a special jury for each contest, on the recommendation of its Quebec ami Montreal sections.Each section makes the recommendation for the jury members appointed to sit in its city, at a special meeting convened for that purpose.This jury is made up as follows: a) Of a member of the Quebec Academy \"f Music; 6) Of two imlcpendcnt members having no connections with this institution.The jury is duly completed when each percon invited by the Aea«lemy of Music has accepted the invitation in writing.13.Non-eligibility: Me y not form part of the jury: a) Any person who has been the candidates' professor, «luring the last four years, either privately or collectively; b) Any person relate*! to a camiidate within the «legree «>f cousin germain inclusively.14.Obligation of the members of the sections: At the special meeting Convened to choose the jury, the members of the Quebec and Montreal sections of the Quebec Aca«lemy of Music must take oath to maintain secrecy as to their deliberations.15.Obligations of members of the jury: All members of the jury must keep their appoint ment secret, otherwise their mandate is subject to revocation.10.Presidents of the contests: The président ami vice-president of the Québec Academy of Music will act as presidents of the contests.17.Secretaries and scrutators of contests: The Joint-Secretaries f Music will act as Secretaries in the congests under their respective section.The treasurer of the Quebec Academy of Music will carry on the function of scrutator of the contest held in the section where he lives and in the other section, he will chocse among its members Someone who will preside as scrutator of the contest. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22, 1002, Vol.!>¦',.No.3fi 4807 18° Récusation: Tout officier désigne aux articles Hi et 17 est recusable pour les raisons énumé-rées à l'article 18 et, le cas échéant, la section de la ville où a lieu le concours nomme son remplaçant.19° Allocution des membres «les jurys et «les officiers: Ix-s membres «les jurys reçoivent chacun, pour la durée des concours, une allocation de soixante-cin«i dollars ($05.00) pur jour de concours, plus leurs fruis de déplacement el de séjour.20° Date des concours: L'Aca«lémie «le Musi«pie de Québec fixe lu date de la tenue des concours et en donne avis en français et en anglais «lans la Gazette officielle de Quelle, avant le 15 mai.Klle «loit aussi faire publier le mf the jury and officers: Each member of the jury receives, for the durai ion of the contests, an allocation of sixty-five dollars (966.00) for each «lay of the contests plus travelling ami hotel expenses, 20.Date of contests: The Quebec Aeadmy of Music lets the «late OU which the contest will he held ami giv«\\s notice, in Frciu-h ami in English in the Quebec Official Gazette, before May, 15th.The Quebec Academy oiut of intersection «»f the left bank t>f the Outaouais River with the west line of lot 20; thence, successively, the following lines and demarcations: the said west line of loi 20 crossing a small lake ami the west line of lot 27; the south si«le of «le la Reine street going towards the west as far as the extension of the west line of lot 310; the said extension and the said line extending to the west line of lot 312.(Canadian Pacific railway right of way) and going towards the north as far as the north line of lot 310; the north line of l«)ts 310.309.42 ami 307.the latter extende«l along the public road s8 far as the north line of lot 29; the north line of lots 29 ami 28; the east line of lot 28 extending to the east line of lot 312 (Canadian Pacific railway right of way) crossing de la Reine street ami going towards the south as far as the south Ik'ii of lot 28; the east line of lot 1 extended on the Outaouais River as far ils the Quebec-Ontario interprovincial boundary line; the said Quebec -Ontario interprovincial boundary line going towards the south-west as far as the extension of the west line of lot 20: the said extension as far as the starting point; For this purpose a census was onlered to be taken by the council, and the population is numbered at 3,421 souls as of June 10, 1902.The municipality of the town of Thurso will be erected into a town under the authority of the Cities and Towns Act.Signet! at Thurso, district of Hull, Province of Quebec, this 7th day of September, 1902.Rodolphe Pelletieh, Mayor.E dmon d Bot leki ce, 005-37-2 Secretary-treasurer.City of Montreal Notice of Redemption To the holders of debentures payable in ameri-can currency of the issue designated \"5 5/8% sinking fun«l debentures for public woiks «lue November 1, 1979\" of the city of Montreal.Public notice is hereby given that the city of Montreal intends to and will redeem FOR SINKING FUNDS PURPOSES on November 1, 1902, pursuant to the provisions of the debenture contract, the following debentures payable in American Currency of the above mentioned issue on November 1, Î979, listed below at 100% of the face value thereof plus accrued inteiest to the redemption date, namely: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Septemfcr 22, VMli.Vol.H-'\u201e So.SS \u2022ison Obligation numéro: 6276966 K2' Y.Ï R2! E2! B2! Y;l Y:l r.j fat vas Y:l Y:l Y:l Y:l Y:2 Y/2 Y:l K2 1:2 1:2 !\u2022:_> 1:2 K2 B2 R2 1:2 K3 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 E2 l'.2 i:2 l'.2 I-.2 F.2 i:2 i:2 M2 M2 i:2 6991 7004 700S 7006 7007 7006 7060 7081 7082 7083 7080 7044 7106 7107 7112 7132 7145 7147 7150 7100 7101 7102 7194 7208 7209 7205 7283 7307 7308 7317 7359 7395 7402 7432 7447 7408 7409 7010 7018 7070 7084 7085 7080 7088 7089 7090 7091 E277702 K277717 K277720 E277762 E277784 E277829 E2778G3 E277979 E277987 E277088 K277992 E278003 E378011 E278012 E278013 E27S014 E27S015 R278078 E278076 E278077 E278078 E278079 E278080 E27K120 E27S143 E27S144 E278217 E27S225 E278260 E27K270 E278301 E27S411 E27S412 E278413 E278414 E278417 E27842S E278429 E278430 E27H433 E278480 E278507 E278527 E278542 E278592 E278593 E278597 E27859S E27K599 E27SOOO E27SC01 B278602 B378603 E278W14 E278M5 E278»»0l> E278007 E287008 E27S009 E278G10 E278G28 E278708 E27K734 E27874G E27S74S E27S749 E278750 E278H09 E278H81 E278882 E27H8S3 E27H89S E27S955 E27S950 E278957 E27H959 E278902 E279012 E279027 E27902S E279031 E279009 E279070 E279071 E279089 E279090 E279090 E279107 E279122 E279200 E279239 E279343 E279307 E279402 E279405 E279412 E2H3498\tE284528\tE285529 K2X3540\tE284529\tE285533 E283544\tE284530\tE285534 K2K3017\tE284531\tE285535 K28:i033\tE284532\tE285555 K283034\tE284533\tE285505 K283049\tE284534\tE285008 E283G50\tE284535\tE285009 E283651\tE284530\tE285081 E283663\tE284537\tE285701 E283664\tE284550\tE2S5702 E28366S\tE284557\tE285703 E283070\tE284500\tE285704 E283073\tE284G19\tE285705 E283714\tE284G22\tE285700 E283710\tE284020\tE285708 E283725\tE284077\tE285712 E283745\tE284085\tE285720 E283708\tE284098\tE285721 E283829\tE284099\tE285722 E283842\tE284700\tE285723 E2838G1\tE284700\tE285724 E283892\tE284707\tE285725 E2S3930\tE284713\tE285720 Dqu'iitim' number: ITEM I E279479 E279480 E279481 E279482 E279483 E279484 E279485 R279486 E279491 E279492 E279549 E27958C, E279589 E279593 E279594 E279007 E279(i08 E279699 E279704 E279711 E279712 E279704 E279812 E270880 E279S90 E279929 E279930 E279970 E280003 E28(K)40 E2800G4 E280084 E280212 E280200 E280304 E28040G E280542 E280543 E280553 E280587 E280033 E280034 E280700 E280712 E280713 E280721 E280722 E280724 ITEM II E2S0005 E28()000 E280007 E280(X)8 E28(i009 E280013 E280015 E280010 E280017 E280113 E280117 E280105 E280175 E280192 E280273 E280295 E28f>321 E280329 E28(W41 E28()342 E820309 E28G374 E280380 E280387 E280744\tE281200\tE283I01 E280756\tE281329\tE283I20 E280757\tE2S1330\tE28Î1I70 E2.s07r,()\tE2K1340\tE2H3178 E28070.\")\tE281384\tE2K3227 E280760\tR281390\tE283287 E2807(>7\tE281417\tE283201 E2807(>8\tE281422\tE283305 E2807(>9\tE28I424\tE283338 E280770\tE281450\tE283339 K2S0797\tE2K1452\tE283340 E280801\tE281040\tE283311 E280826\tE281722\tE283347 E280S11\tE2S1770\tR288848 E280S42\tE281793\tE283301 E2808«',S\tE281794\tE282302 E280870\tE2818S5\tB283868 E280880\tE281S90\tE2833«il E280899\tE281891\tK2S3388 E2S01MM)\tE2S1924\tE283389 E280902\tE281928\tE2K3390 E280914\tE281929\tE28:i412 E280919\tE281977\tE28.3423 E280927\tE281999\tE2S3428 E280941\tE2820C1\tE283429 F280943\tE282021\tE283430 E281001\tE282037\tE283431 E281002\tE282050\tE283432 E281003\tE282002\tE283433 E281004\tE282259\tE283434 E281024\tE2822G3\tE283455 E281025\tE282349\tE283450 E281026\tB282860\tE283478 E281027\tE282391\tE283479 E281028\tE282395\tE283480 E281029\tE282452\tE283481 E281030\tE282457\tE283482 E281031\tE282479\tE283483 E281032\tE2S2550\tE283484 E281033\tE282551\tE283485 E2S1034\tE28255G\tE28348G E281035\tE282505\tE283487 E281142\tE2825(i0\tE283488 E281149\tE282042\tE283492 E2811G1\tE282713\tE283493 E281197\tE282714\tE283494 E281200\tE283001\tE283495 E281235\tE28309C\tE283497 E287232\tE287943\tE288880 E287233\tE287972\tE288883 E2S7234\tE287977\tE288947 E287246\tE287988\tE288950 E287271\tE2.S8000\tE288957 E2873G4\tE288001\tE2.8970 E287388\tE288050\tE288971 E287392\tE288084\tE288972 E287393\tE28S085\tE288973 E287427\tE288190\tE288979 E287428\tE288221\tE289021 E287429\tE28S224\tE289042 E2S7457\tE288234\tE289000 E287458\tE288250\tE289122 E2874G3\tE288323\tE289123 E2874GG\tE288345\tE289124 E287477\tE288385\tE289125 E287529\tE288452\tE289120 E287631\tE288507\tE289142 E287032\tE288514\tE289215 E287044\tE288515\tE289284 E287G45\tE288510\tE289285 E287G40\tE288531\tE289280 E287047\tE288532\tE289287 4810 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 septembre 11)62, Tome 1)4.So 38 E283Ô37\tE284728\tE285727\tE280389\t10287O48\tE288533\tE2892SS E283939\tE284741\tE285728\tE280414\tE287049\tE288(M)3\tE289280 E283963\tE284753\tE285729\tE280420\tE287G50\tE288005\tE289290 K28397I\tE284848\tE285730\tE280490\tE287051\tE28S044\tE28921M E283990\tE284849\tE285731\tE280494\tE287052\tE2880G8\tE289:i2 1 E283991\tE284850\tE285732\tE280503\tE287(Î54\tE288Ô09\tE289:i2'i E284014\tE28494G\tE285740\tE280547\tE287G72\tE288G90\tE289343 E284048\tE284991\tE285741\tE280597\tE287083\tE288(i97\tE28935!) E284050\tE285060\tE285750\tE280G01\tE287704\tE288701\tE28937!» E284142\tE285070\tE285819\tE280Ô09\tE287707\tE288747\tE289443 E284197\tE285077\tE285840\tE280052\tE287733\tE288751\tE2894(i:5 E284254\tE285123\tE285851\tE286653\tE287737\tE288765\tE289172 E284325\t£285150\tE285930\tE28G885\tE287738\tE2887S7\tE28950S E284394\tE285151\tE285937\tE28(>9()7\tK2S7739\tE288788\tE28952V E2844O0\tE285250\tE285938\tE380912\tE287742\tE288794\tE28955I E294434\tK285252\tE285900\tE280922\tE287815\tE288802\tE289645 E2844G0\tE285254\tE285967\tE280997\tE287825\tE288809\tE2890.-)S E2844G1\tE2S.-.279\tE285969\tE287031\tE287820\tE288819\tE289662 E284170\tE285280\tE2859S7\tE287050\tE287827\tE288824\tE28967!) E28447I\tE2S/^2S3\tE280000\tE287095\tE28782S\tE288858\tE289GS0 E284474\tE285289\tE280001\tE287171\tE287829\tE28S8G7\tE28968I E284525\tE2S5322\tE280002\tE287187\tE287834\tE2888G8\tE289082 E28452G\tE285308\tE280003\tE287223\tE287912\tE288872\tE289G83 E2S4527\tE285410\tE286004\tE287231\tE287942\tE28S873\tE2S9CSI \t\t\tITEM III\t\t\t E289685\tE2902JS\tE291498\tE292809\tE294009\tE294805\tE29588 i E289G91\tE290292\tE2915I8\tE292848\tE294010\tE294S07\tE295891 E289098\tE290843\tE291519\tE292852\tE294011\tE294842\tE295S0Ô E289717\tE290388\tE291522\tE292853\tE294012\tE294850\tE29590! E289719\tE290389\tE291528\tE292854\tE294017\tE2948\"d\tE29595C.E289747\tE290455\tK291001\tE292855\tE294018\tE2948G2\tE295982 E289751\tE29045G\tE291699\tE29285G\tE294028\tE294803\tE290009 E2898Ô2\tE290580\tE291749\tE292857\tE294050\tE294887\tE29C>07«) E289853\tE290606\tE291750\tE293010\tE294003\tE294S99\tE29titiss E289910\tE290G32\tE291751\tE2930U\tE294O70\tE294950\tE296096 E289911\tE290G4S\tE291753\tE293012\tE294077\tE2949G2\tE2901Ô7 E289912\tE290733\tE291784\tE293014\tE294148\tE294973\tE290I5S E2X9931\tE290741\tE291789\tE293020\tE294194\tE294982\t1296272 E289941\tE290700\tE291840\tE293097\tE294195\tE294999\tE29()2S2 E2S9995\tE290778\tE291845\tE293125\tE294190\tE29502G\tE296302 E289990\tE290779\tE291848\tE293120\tE294197\tE295089\tE29G30S E2S9997\tE290780\tE291850\tE293129\tE294231)\tE295090\tE296375 E289998\tE290784\tE291940\tE293130\tE294251\tE295105\tE29G430 E2S9999\tE290S00\tE291945\tE293233\tE294252\tE295122\tE29al Trust Company ou au bureuu «le The Royal Bank of Canada Trust Compuny, Borough of Manhattan, cité et état «le New-York, Etats-Unis d'Amérique, sur présentation et remise desflites obligations avec tous les coupons «l'intérêt échi'ant upiès le 1er novembre 1902 attachés.Les «ihligntions «'inegistrccs quant au principal devront être accompagnées de transferts ou «le procutation autorisant tels transferts «lûinent signés eu blanc.A compter «lu et après le l«'i novembre 19(12.l'intérêt sur les obligations ainsi rappelées pour rachat cessera et les coupons d'intérêt échéant siibscqucmmcnt à «\u2022 tte «late sen nt nuls.Duté à Montréal, ce quinzième jour de septembre 1902.Cité «le Montréal, Le Directeur des Finances, G30-o L.Rqhebge.Ville de St-Eu*tache St-Eustache.10 août 1902.À qui «le «boit: Prenez avis «pic les articles suivants «lu bill privé 225.soit la Loi nuxlifiant la chatte de la ville «le St-Kustache.adopté à la 3ème session.20ème législature.11, Elisabeth II.1902.ont «;té sanctionnés le ti juillet 1962: Article 1: Las canalisations d'égouts sous les rues et ehemins publics «le la ville de St-Eustache sont censées être la propriété «le la ville de St-Eustaehe et toute réclamâti«>n et droit d'action «le propriété «le CCS canalisations sont ahs«>lumcnt éteints et prescrits, s'ils n'ont pas été esercés par une action intentée «levant une cour de justice Compétente «lans l'année «le la sanction «le la présente loi dont le présent article sera publié une fois par mois pendant une période «le «lix mois en français dans un journal français «piotidien et eu anglais dans un journal anglais quotidien en circulation duns lu ville «le St-Kustaehe, ainsi qu'à «leux reprises «lans la Gazette officielle de Québec, à intervalle de six mois.Article 2: Les trottoirs actuellement construits parallèlement aux rues suivantes, et les terrains sur lesquels ils sont situés, sont censés être «les trottoirs et des terrains publics et la propriété «le la ville de St-Kustache qui en aura, à l'avenir, l'entretien, sur toute leur superficie mais sur une profondeur ne dépassant pas celle indiqué»' ci-après, en prenant comme point de départ la ligne «le pavage actuellement existante sur les «lites rues: a) Quant à la rue St-Eustache: sur une profondeur ne dépassant pas rinquante-quatre (54) pouces; b) Quant à la rue St-Louis: sur une profondeur ne dépassant pas cinquante quatre (54) pouces; c) Quant à la première Avenue: sur une profondeur ne dépassant pas trente-six (30) pouces; d) Quant à la deuxième Avenue: sur une profondeur ne dépassant pas trente-six (30) pouces; e) Quant à la troisième Avenue: sur une profondeur ne dépassant pas trente (30) pouces; /) Quant à la quatrième Avenue: sur une profondeur ne dépassant pas «piarante-deux (42) pouces; g) Quant à la cinquième Avenue: sur une profondeur ne dépassant pas soixante (00) pouces; The debentures *> called for rédemption will become due and payable and will be pan I in such coin or such currency f The Royal Hank «>f Canada Trust Company in the Borough of .Manhattan, city and State of New York, United States of America, 11000 presentation and \u2022urtender «>f the said debentures with all interest coupons maturing after November I, 1902 attached.Debentures registered as to principul must be a«:coinpanied by assignments or transfer powers duly executed in blank.Prom ami after November 1.1902.inteiest on the debentures SO called for redemption will cease and interest coupons maturing subsequent t«> that date will be void.Dated at Montreal, this fifteenth «lay of September 1902.City of Montreal.L.Roukuck, 696*0 Dire< tor of Finance.Town of Sl-Kuslaehe St-Kustaehe.August 10, 1902.To thorn it may concern: Take notice that the billowing sections of private bill 225 that is an act to amend the charter of the town of St-Kustache.passed at the 3rd session of the 20th legislature 11.Elisabeth II, 1902, have been sssmtnd to the July o, 1902.Article 1: The sewer pipes under the streets ami public roads of the town of St-Eustachc are deemed to be the property of the town of St-Eustache and any claim ami right of action for ownership of such pipes shall be absolutely extinguished and prescribe*!, if they have not been exercised by action instituted before a competent court of justice within one year from the sanction of this act, this section of which shall be published «>nce monthly during a perkx! of ten months in French in a French daily newspaper and in English in an English daily newspaper circulating in the town of St-Eustache, as well as twice in the Quebec Official Gazette at intervals of six months.Article 2: The sidewalks presently paralleling the following streets, ami the land on which they are located, are deemed t«i be public sidewalks ami Iund ami the property of the town of St-Eustachc which shall hen-after have the maintenance thereof «>ver their whole area but to a depth not exceeding that hereinafter^indicated, measured from the presently existing paving line on the said streets: a) On St-Kustaehe Street: a depth of not more than fifty-four (54) inches; 6) On St-Lou is Street: u «lepth of not more than fifty-four (54) inches; e) An First Avenue: a «lepth of not more than thirty-six (30) inches; d) On Second Avenue: a «lepth of not more than thirty-six (30) inches; e) On Third! Avenue: a «lepth of not more than thirty (30) inches; /) On Fourth Avenue: a «lepth t>f not more than forty-two (42) inches; g) On Fifth Avenue: a «lepth of not more than sixty (00) inches; 4X12 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC 22 topkmbn 196S, Tome u/h No 88 h) Quant à la rue Saint-Nicolas: sur une profondeur ne dépassant pas trente-six (86) DOUOMi 0 Quant à la rue Debcllefeuillc: sur une profondeur ne dépassant pas tiente six (86) pouces; j) Quant à la Tciras.se Parent: sur une profondeur ne dépassant pas trente-six (30) pOUCef.Toute réclamation cl droit d'action de propriété de ces trottoirs et «le ers terrains sont uhsulumciit éteints et prescrits, s'ils n'ont pus été exercés par une action intcntir devant une cour de justice compétente duns l'année «le lu sanction de la présente l«»i «lotit l«- présent article sera publié une fois par mois pendant une période de dix mois eu français dans un journal français quotidien et en anglais dans un journal anglais quotidien en circulation dans la ville de St-Kustache.ainsi qu'à «leux reprises duns la Oazttte officielle de Québec, à intervalle de six mois.Veuille/ donc vous gouverner en conséquence* Le Procureur de lu ville de Sl-Euêtaohê, 656-88-841 Hiciiahi) La Ciiaiutk.Ville de Lorcttevllle Règlement numéro .',11 prolongeant à trois ans les fonctions du maire et «les échevins Attendu «pie le conseil est «l'avis «le porter à trois ans, à compter «les élections «pli suivront l'entrée en vigueur «lu présent règlement, la durée «les fonctions «lu maire et «les échevins; Attendu qu'un avis de motion a été donné préalablement à l'adoption du présent règlement; Vu les dispositions «le l'article 173-a «le la Loi des cités et villes; En coneéquence, il est ordonné et statué par règlement «le ce conseil ce qui suit: 1.À compter «les élections qui suivront l'entrée en vigueur du présent règlement, lu durée des fonctions «lu maire et des échevins sera «le trois ans, et l'élection générale «lu maire et des échevins «le la ville de Loretteville aura lieu à tous les trois ans; 2.Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi.Atlopté en deuxième et «lernière lecture le quatrième jour «le septembre 1962.lé Secrétaire-trésorier, 670-o Paul A.Cantin.h) On St-Nicholas Street: a «lepth of not more than thirty-six (36) inches; i) On Debcllefeuillc Street: a «lepth of not more than thirty-six (30) inches; j) On Terrasse Parent: a depth of not more than thirty-six (86) inches.Any claim ami right of action for ownership of such sidewulks and land- shall be absolutely eatinguished and proscribed, if they have not been «'xercis«'«l by uction instituted before a competent court «>f justice within one year from the sanction of this act, this section of which shall be published once monthly during a period of ten months in French in a French duily news, paper ami in English in un English daily newspaper circulating in the town of St-Eusta«he.BS well as twice in the Quebec Official Oazettt at intervals of six months.Do govern yourself accordingly.Rich Abo La Chauitk, 656-38-3-0 Attorney for the town of St-Eustache.Town of Loretteville Ry-law numlwr Jtll entending the term of office «>f the mayor ami the aldermen to three years Whereas the council is of opinion to extend to three years the term of office of the mayor ami the aldermen as of the elections following the coming into force of the present by-law; Whereas notice of motion has been given prior to the adoption of the present by-law; Seeing the dispositions of article 173-a of the Cities ami Towns Act; Accordingly, it is ordered and decreed by the council as billows: 1.As of the elections following the coming into force of the present by-law, the term of office of the mayor and aldermen shall be of three years an«l the general election of the mayor and aldermen of the town of Loretteville shall take place every three years.2.The present by-law shall come into force according to law.Adopted in second ami last reading on the fourth day of Septeml»er, 1962.Paul A.Cantin, 670-o Secretary- Treasurer.Cité de Saint-Jean Prenez avis que le conseil «le la cité «le Saint-Jean présentera une requête au lieutenant-gouverneur de lu province «le Quél>ec, pour demander que soient émises «les lettres patentes accordant la permission d'insérer dans la charte de la cité les articles 68, 68a, 68b, 360, le paragraphe premier de l'article 420, 429, 430, 431 et 432 de la Loi des cités et villes.Saint-Jean.17 septembre 1902.Ia> Procureur du conseil de la cité, 071-o Roland Thkmhi.ay.City of Saint John's Take notice that the council for the city of Saint John's will present a request to the Lieutenant -Oovernor of the Province of Quebec, to ask that letters patent lie Issued granting the permission to insert in the city's charter sections 68, 68a, 68b, 360, the first paragraph of section 426, 429, 430, 431 and 432 of the Cities and Towns Act.Saint John's, Septeml>er 17, 1902.Hoi.an d Tkkmblay, 671 Attorney for the city council.Compagnie autorisée Company Licensed à faire des affaires to do Business Pindar Holding Aktiengesellschaft Pindar Holding Aktiengesellschaft Avis est donné que « Pindar Holding Aktiengesellschaft », compagnie à fonds social étrangère, constituée en vertu de Statuts «le la Principauté de Liechtenstein, a été autorisée a faire affaires Notice is hereby given that \"Pindar Holding Aktiengesellschaft\", an extra-provincial company incorporated under the Statutes of the Principality of Liechtenstein, has been licensed QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 22.IM2, Vol.H.',, So.dS 4X13 \u2022 lans la province de Quebec, conformément uux dispositions de lu I ah des compagnies ù fonds social étrangères.Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 279.L'agent principal de ladite compagnie dans la province, aux fins de recevoir les significations en toutes actions et procédures exercées «\u2022outre elle, est monsieur f Montreal, will apply to the Attorney General of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Montreal.September 12.1902.(Signed) ChabBOM & Mekcikk.615-0 A ttorneys for the coin pan if.Astoria Construction Inc.Take notice that \"Astoria Construction Inc.\", with head ollice in the city ami «listriet of Montreal.Quebec, will apply for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Quebec Companies' Act.Montreal.P.Q.September 14.1902.Cbbiki & Jamikson, 688-0 Attorneys for the }tetitioners.Domaine St.Eustacbe Ltée Take notice thut ''Domaine St.Eustacbe Ltée\", with hea«l office in the city of Côte St.Luc, Quebec, will apply for leave tt> Surrender its charter in accordance with the provisions t>f the Quebec Companies' Act.Montreal.P.Q.September 13, 1902.Ckhini ft .Iamikson, 024-o Attorneys for the petitioners.Eros Knitting Mills Ltd.\"Take notice that \"Eros Knitting Mills Lt«L\".will petition the Attorney General of the Province of Quebec f«>r permission to abandon its charter.\" Montreal.September 11, 1902.L(h is (il.azkh.q.c, Attorney for 025-o Eros Knitting Mills Ltd.Ronsard Construction Inc.Notice is hereby given that \"Ronsard Construction Inc.\", a corporation duly incorporated 4814 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 septembre I960, Tome 04, No 38 incorporée on vertu de In Iioi «les compagnies de Québec et ayant son siège social et principale plaee d'affaires en la cité de St-Michel, province de Québec, Canada, demandera la permission au Secrétaire do lu province do Québec d'abandonner sa charte suivant les dispositions de ladite Iah.Daté à St-Michcl, ce 13e jour de septembre 1902.l.e Secrétaire, 001-o Hit a Lamothk.Le Domaine des Dix Frères Inc.Prenez avis que la compagnie « Le Domaine des Dix Frères Inc.», demandera au Procureur général la permission d'abandonner sa charte.Le Procureur de la compagnie, 073-o Me GlLLBS Dkmkus, notaire.under the Quebec Companies Act and having its head oflice ami principal plaee of business in the city of St.Michel, Province of Quebec, Canada, will apply to the Provincial Secretary of the province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the said Act.Dated at St.Michel, this 13th day of September 1902.Rita Lamothk, 001-o Secretary.Le Domaine des Dix Frères Inc.Take notice that \"Le Domaine dos Dix Frères Inc.\", will apply to the Attorney (îeneial for permission to surrender its charter.Mo Gilles Dkmkus, Notary, 073 Attomey for the ( 'ompany.Divers Compagnies Les Éditions du Jour Inc.Erratum Dans l'avis do la compagnie piéeitée, publié dans la Gazette officielle de Québec No 37, du 15 septembre 1902, à la page 471 S, veuillez apporter la correction suivante: dans la première ligne du texte français, veuillez remplacer le mot « vingt » par le mot « cinq », la phrase se lisant effectivement: « un règlement qui porte à cinq le nombre des directeurs ».557-x Miscellaneous Companies Les Éditions du Jour Inc.Erratum In the notice ol the aforementioned company, published in the Quebec Official Gazette, No 37, on September 15, 1902, on page 4718, kindly make the following correction: in the first line of the French text, kindly replace the word \"vingt\" by the word \"cinq\", the sentence reading effectively: \"un règlement qui porto à cinq le nombre des di recteurs\".557-x Lacobran Property Management Corporation Ltd.La Compagnie d'Administration Immobilière Lacobran Ltée Règlement So XIV « Que le nombre des directeurs do la compagnie soit augmenté de trois à quatre directeurs.» Montréal, le 14 juin 1902.Certifié vraie copie.Le Secrétaire, Roger Comtois.OlO-o 11893-02 The Army, Navy & Air Force Veterans in Canada, Montreal Central Unit No.346 Inc.Avis est donné que les règlements Nos 1, 2 et 3 de « The Army, Navy & Air Force Veterans in Canada, Montreal Central Unît No.340 Inc.», furent approuvés par le secrétaire de la province, le 13 septembre 1902, conformément aux dispositions de l'article 225a, do la Loi dos compagnies de Québec.Donné au bureau du secrétaire do la province, ce 17e jour de septmbre 1902.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.020 12005-02 Nap.Duniont Ltée Règlement Xo 35 concernant la modification du nombre des directeurs.« Le nombre des directeurs de la compagnie « Nap.Dumont Ltée », est changé de trois (3) qu'il Lacobran Property Management Corporation Ltd.La Compagnie d'Administration Immobilière Lacobran Ltée By-law Xo.XIV \"That the number of directors of the company be increased from throe to four directors.\" Montreal.June 14, 1902.Certified true copy.Rockh Comtois, Secretary.010 11893-62 The Army, Navy & Air Force Veterans in Canada, Montreal Central Unit No.346 Inc.Notice is hereby given that by-law Nos 1, 2 and 3 of \"The Army, Navy & Air Force Veterans in Canada.Montreal \u2022Central Unit No.340 Inc.\", were approved by the Provincial Secretary on September 13, 1902, pursuant to the provisions of section 225a, of the Quebec Companies Act.Civen at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of September, 1902.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.020-o 12005-02 Nap.Dumont Ltée By-law Xo.35 concerning the altering of the number of directors.\"The number of directors of \"Nap.Dumont Ltée\", has been changed from three (3) as it QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, September 22.1062, Vol.Ott, So.38 4815 était auparavant à celui de cinq (5) et le règlement no 3 de la compagnie est modifié en conséquence.» Copie certifiée du règlement No 35, de la compagnie « Nap.Dumont Ltée », dûment adopté à une assemblée «les directeurs tenue le 14 août 1962 «'t approuvé à une assemblée générale upéciale de la compagnie tenue le 14 août 1962, par les actionnaires détenant entre eux (100%) .les a.35.of \"Nap.Dumont Ltée , duly adopted at a meeting of the directors held on August 14, 1902, ami approved at a special general meeting of the company held on August 14.1902.by the shareholders holding among themselves (100%) of the shares represented at this meeting.M Al HICK W.SoUCY, Secretary.027 10227-54 Les Kmployeurs Forestiers de la Mauricie, Inc.Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary bus.on September 11.1902, approved by-law number one of \"Les Kmployeurs Forestiers «le la Mauricie.Inc.\".and such, pursuant to the provisions of section 225a, of the Quebec Companies Act.(iiven ut the office of the Provincial Secretary, ou September 11, 1902.Raymond Dm -ville, Assistant Secretan/ of the Province.628 13373-02 National Bowling Centres Ltd.\"Special by-law \"C\" 1.The number «>f directors of the company be ami the same is hereby increased from seven (7) to nine (9) so that the board «>f directors of the company shall hereafter be composed of nine directors.2.Five (5) directors shall constitute a quorum at any meeting «>f the board of directors.3.All prior by-laws, resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith ure hereby amended, moomed ami revised in order t«> give effect to this by-law.\" Certified a true copy «>f spécial by-law \"C\" enacte«l by the «lireetors «>f National Bowling Centres Ltd.\", on the 25th day of July, 1902, ami approved by at least two-thinls in value of the shares represented at a special general meeting «)f shareholders of the company held on the 28th day of August.1902.(Signed) ROBERT CCMMINGS, Secretary.029-o 10900-61 Conio Golf Club Club de Golf Como Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has, on September 12, 1962, approved the by-laws I to VIII inclusively of \"Como Golf Club \u2014 Club «le Golf Como\", and such, pursuant to the provisions of section 225 of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, the 14th day of September, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretan/ of the Province.645 13255-62 Crédit du Lac Inc.By-law No.15 concerning the altering of the number of directors.\"The number of directors of \"Credit du Lac Inc.\", has been changed from five (5) as it 4816 QAZETTK OFFICIELLE DE QVEHEl, 22 septembre 1962.Tome U/t, No SX qu'il était auparavant ù celui «le sept (7) et l'article un (1) «lu règlement troisième est modifié en cojuéquence.» .le, soussigné, Muuritc Roy, secrétaire «le « Crtslit «lu bac Inc.», eertilie, par lu présente, sus le sceau corporation «le lu compagnie, que f the shar«\\s represented at this meeting.Mai un k Roy, Secretan/.640 12084-62 Donirémy Luc-M«:gaiit ie Inc.Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has.on August 13, 1062, approved the by-laws numbers 1, 2 and 3 of the corporation \"Donirémy Lsc-Mégantic Inc.\".ami such pursuant to the provisions of section 225, of the Quebec Companies Act.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, on August 16, 1962.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.647 10824-ti-' Ronsard Construction Inc.Avis est par les présentes «lonné qu'en vertu du règlement spécial « A » de « Ronsard Construction Inc.», dûment édicté et promulgué par lis direct-urs et approuvé «t ratifié par les actionnaires de li compignie, la compagnie a été autorisée, sujet aux dispositions dirait règlement et aux exigences «le l'article 90, de la L« i «les compagnies de Québec, à abandonner ses biens et à distribuer son actif à s( s actionnaires.Daté à St-Michel.ce 13e jour «le septembre 1902.Le Secrétaire, 001-o Rita Lamothe.Ronsard Construction Inc.Notice is hereby given that umler the special by-law \"A\" of \"Ronsard Construction Inc.''.«hily enacted ami passai by the directors and approved and ratified by the shareholders of the company, the company has been authorized, subject to the provisions of said by-law and the requirements of section 90, of the Quebec Companies Act, to surrender its pr« perty and distribute its assets to its shareholders.Dated at St.Michel, this 13th day of September 1902.Rita Lamotiie, 001-o Secretan/.Caribonum Limited Loi des compagnies à fonds social étrangères Avis est «lonné que, par une nouvelle procuration datée du 4 septembre 1902, dont une copie a été transmise au secrétaire de la province, M.James Charles Allen, «le la cité de Montréal, a été nommé agent principal dans cette province de « Caribonum Limited », une compagnie ù fonds social élnuigère dûment autorisés à exercer son commerce dans la province «le Québec, en vertu de la Loi des compagnies à fonds social étrangères ci-dessus mentionnée, en lieu et place de M.John Eardley Pocock, «le la cité de Montréal.Avis est aussi donné «pie, conformément à la nouvelle procuration susmentionnée, le siège social de « ( 'a ni ion uni Limited », dans la province, est établi à 2SG ouest, rue St-Paul, en la cité et «lans le «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour «le septembre 1902.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.674 165-48 Caribonum Limited Extra-Provincial Companies Act Notice is hereby given that, by new power «»f attorney, dated September 4, 1962, a copy of which has been transmitted to the Provincial Secretary, Mr.James Charles Allan, of the city of Montreal, has been appointed, in lieu of Mr.John Eardley Pocock, of the City of Montreal, chief agent in this Province of \"Caribonum Limited\", an extra-provincial company duly licensed to carry on business in the Province of Quebec in virtue of the above-mentioned Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that, acconling to the above-mentioned new power of attorney, the principal office of \"Caribonum Limited\" in the Province is established at 286, St.Paul Street West, in the city and in the judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of September, 1962.Raymond.Douville, Assistant Secretary of the Province.674-o 165-48 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.September 22, 1962, Vol.nv«>«piéc et tenue le 7 mai 1902, à laquelle fous les actionnaires étaient présents.Le Secrétaire, Fie AN K SPKNAIcD.075- 15714-52 Lettres patentes Foyer Thérèse .Martin Avis est «lonné «pi'en v«-rtu «les dispositions «le l'article 20, «le la Ix>i des cvctpics eatb«»li«iues romaine, 14 George VI, n, \u2022¦il vertu «le lu première partie «le la Ix>i «les compagnies de Québec, pur lettres patentes datées du 2 décembre 1958, a transporté son siège social de 777 ouest, boulevard Dorchester, en la cité de Montreal, à Un, Place Ville Marie, en la cité «le Montréal.Montréal, 30 juillet 1902.Le Secrétaire, 018 IL L.Munro.Sterling Finunce Corporation H y-laic number t concerning un increase in the number of directors from 4 to 7.\"1.Number -the affairs of the company shall be administrated by a board «>f director! composed f seven (7) directors.14.Quorum The quorum shall be «»f four directors.\" True excerpt «»f the new by-law number 1 of \"Sterling Finance Corporation\" unanimously adopted at a meet ing of tin- sharchohlcrs regularly convened and held on May 7, 1062, at which all the shareholders wen- présent, FllANK Sl'KXAKD, Secretary.075-o 15714-52 Letters Patent Foyer Thérèse Martin Notice is hereby given that pursuant to the provisions of section 20, of the Roman Catholic Bishops' Act, 14 Ceorge VI, chapter 70, the Lieutenant-Governor of the Province ol Quebec has issued letters patent, dated August.27, 1902, incorporating \"Foyer Thérèse Martin\".The head office of the above mentioned corporation is siluate One, Place Ville Marie, in tin city of Montreal.Montreal, July 30, 1962.R.L.Munuo, 019-o Secretary.Clarke Place Investments Inc.Avis est «lonné que lu compagnie « Clarke Place Investments Inc.».constituée en corporation par lettres patentes en date du S juin 1902, et ayant son siège social en la cité «le Westmount, a établi «on bureau au No 032, avenue Clarke, Westmount.À compter «le la «late de cet avis, ledit bureau sera considéré comme étant le siège social de la compagnie.Daté à Westmount, P.Q.ce 13e jour de septembre 1902.Le Secrétaire, 020 E.Evans.Clarke Place Investments Inc.Notice is hereby given that \"Clarke Race Investments Inc.\", incorporated by letter patent dated June 8, 1902 und having its head office in the city of Westmount, has established its office at No.032 Clarke Avenue, Westmount From am! after the «late «>f this notice the laid office shall be considered by the company at being the head office of the company.Dated at Westmount, P.Q., this 13th day of September, 1902.E.Evans, 020-o Secretary.Chrétien & Lambert Liée Avis est donné «pic la compagnie « Chrétien & Lambert Ltée », constituée en cori>oration par lettres patentes en «late du cinq mai, mil neuf cent soixante et un, ayant son bureau principal en la cité «le Jonquière, a établi son bureau à 287-B, rue St-Dominique, en la cité de Jonquière, «listriet judiciaire de Chicoutimi.À compter «le la date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Jonquière, ce trentième jour «le mai, mil neuf cent soixante et un.Le Secrétaire, 021 -o , L.A.Lambkrt.Chrétien & Lambert Ltd.Notice is given that the company \"Chrétien & Lambert Ltd.\", incorporate*! by letters patent date(l May five, one thousand nine hundred and sixty-one, having its head office in the city of Jonquière, ihas established its office at 287-B, St-Dominique Street, in the city of Jonquière, judicial district of Chicoutimi.From and after the «late of the present notice, the sait! office Ls considered by the company as being its head office.(îiven at Jonquière, this thirtieth day of May.one thousand nine hundred and sixty-one.L.A.Lamrkkt, 021 Secretary.Les Constructions Lido Ltée Avis est donné que le bureau principal «le la compagnie « lies Constructions Lido Ltée » est situé au numéro 7K02, de la rue Chabot, à Montréal.Montréal, le 7 septembre 1902.Le Secrétaire, 622-o Roland Paquin.Les Constructions Lido Ltée Notice is hereby given that the hea«l offici of the comi>any \"Les Constructions Lido Ltée* is\" situated at No.7802, Chabot Street, at Montreal.Montreal, September 7, 1902.Roland Paquin, 022-o Secretary.Cana-Plastic Co.Ltd.Règlement 23 Un règlement changeant l'adresse «lu siège sue ia I de la compagnie Qu'il soit décrété et il est décrété comme suit: 1.Ia* siège social f the present notice, the said ofliee situated at number 390, Notre-Dame de Fatima Street, city of Pont-Vian, is considered by the company as being its head office.Given at Pont-Viau, this 5th day of September, 1902.(S«'al) Thérèse Pehhier Bui net, 041 Secretan/.Les Employeurs Forestiers de la Mauricie Inc.Notice is hereby givra that \"Les Employeurs Forestiers «le la Mauricie Inc.\", a companj incorporated by letters patent under the third part of the Quebec Companies' Act, dated August 13, 1902.ami having its hea«l oflice in the city of Trois-Rivières, has established its oflice at number 1332, Notre-Dame street.Prom and after the «late of this notice, the said office shall be Considered by the company as being fhc bead office of the company.Dated at Trois-Rivières.this 30th day of August, 1962.François Lajoie, 042-o Secretary.Vauzc Mines Limited Notice is hereby given that \"Vau/.e Mines Limited*' (No Personal Liability), incorporated under the provisions «>f the Quebec Mining Companies Act on the thirtieth day of May, 1901, and having its head office in the city and «listi ict of Montreal, has moved its office from 80S, Dominion Square Building to 1245, Sherbrooke Street West, Suite 1000, Montreal, Quebec.Dated at Montreal, this 12th «lav of September, 1902.A.Bauer, 043-o Secretary.Waite Lake Mines Ltd.Avis est «lonné que la compagnie « Waite Lake Mines Ltd.» (No Personal Liability), constituée en corporation en vertu «les dispositions «le la Loi «les compagnies minières «le Québec, le vingt-cinquième jour de juin 1959, et ayant son siège social en les cité et «listriet «le Montréal, a transporté son bureau «le 808, édifice «lu « Dominion Square », à 1245 ouest, rue Sherbrooke, chambre 1000, Montreal, Québec.Daté à Montreal.m 244.St.James Street, West.Montreal, to Boom 1500, 507, Place «l'Armes, Montreal I.Dated at Montreal, this 17th dav of September, 1062.A.IL Culver, 6624) Secretary.Port Cartier Transport Inc.Règlement Xo 6 règlement établissant le bureau principal «le la compagnie et annulant le règlement No 4 précédant.« Qu'il soif décrété et il r the couccs-sions on which two years in areais of taxes are due.Notice is hereby given that the mining con-cessions and underground mining concessions, the list of which follows, will revert to the Crown and the letters patent will be annulled, if, within the six months following the first publication of the present notice, the arrears in taxes ami the costs of publication «>f said notice have not bean paid; List of Concessions 1.Mining Concession No.332 comprises the lot 20, range 111, township of .Wot, electoral «listriet «>f Sherbrooke, corresponding to cadastral lots 2()A, 20B, 20C ' and 201) and the part «»f cadastra] lot 29, enclosed within the north line ami the south line of sai«l lot 20 (232.90 acres), ceded to Aldermac Copper Corporation Limited on September 19,1944.and patented on February 7, 1945.2.Mining Concession No.418, comprising the east half of the north half of cadastral lot 26, the east half
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.