Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 avril 1963, samedi 6 (no 14)
[" Tome 95, No 14 1663 Vol.95, No.14 Drapeau de la province de Québec adopté par la Loi concernant le drapeau officiel de la province (14 Geo.VI.ch.3) Flag of the Province of Quebec adopted by the Act respecting the Official Flag of the Province (14 Geo.VI.Ch.3) Gazette officielle de Québec (PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE) Quebec Official Gazette (PUBLISHED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) PROVINCE DE QUÉBEC Quebec, samedi 0 avril 1963 AVIS AUX INTÉRESSÉS Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Spécifier le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous.Cependant, exception est faite lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.L'intéressé doit alors acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.PROVINCE OF QUEBEC Quebec, Saturday, April 6, 1963 NOTICE TO INTERESTED PARTIES Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When same is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Cash payment is exacted for advertising copy before publication, according to the rates he rein be low set forth.Exception being made when the said advertising copy is to be published several times.The interested party shall then pay upon reception of his account and before the second insertion: otherwise this last insertion will be suspended without further notice and without prejudice as regards the rights of the Queen's Printer, who refunds, in all cases, over payment, if any.5.Subscriptions, sale of documents, etc., are strictly payable in advance.L'Imprimeur de ta Reine, roch lefebvre, Queen't Printer \u2014 Québec 1664 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 6 avril 1968, Tome 95, No U 6° Toute remise doit être faite à l'ordre de l'Imprimeur de la Reine, par chèque visé, par mandat de banque ou mandat-poste.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, pour publication, expire à midi, le mercredi à condition que ce jour de la semaine ne soit pas un jour férié.Dans un tel cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toutes demandes d'annulation ou toutes remises d'argent sont soumises aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en avertir l'Imprimeur de la Reine, avant la seconde insertion, et ce afin d'éviter, de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des Annonces: Abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: SI des 100 mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Abonnement: $10 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre réfère à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.L'Imprimeur de la Reine, Rocii Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1962.1515 \u2014 l-52-o Lettres patentes Abaca Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieuUnant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Jean Duchesne, 10955, rue Tan-guay, Paul Reeves, 252, rue Victoria, et Pierre Massé, 3465, Place Decelles, app.501, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Abaca Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.6.Remittance must be made to the order of the Queen's Printer, by accepted cheque, by bank or postal money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the final delay for receiving notices, documents or advertising copy, for publication, expires at noon on Wednesday % providing that this day of the week is not a holiday.In such case, the ultimate delay expires at noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time, will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, due to their length or for reasons of administration.8.Any demands for cancellation or any remittances of money are subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, namely 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $1.per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10.per year.N.B.\u2014 The figures at the bottom of notices have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the Gazette for the first insertion; the third to the number of insertions, and the letter \"o\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notice published but once are followed only by our document number.Rocii Lkfkbvke, Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec, May 5, 1962.1515 \u2014 l-52-o Letters Patent Abaca Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1963, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean Duchesne, 10955 Tanguay St., Paul Reeves, 252 Victoria St., and Pierre Massé, 3465 Place Decelles, apt.501, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and genera! building contractors, under the name of \"Abaca Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, No.U 1665 Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, 00 28e jour de janvier 1963./*?Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.2517-o 233-63\u2014 1158/106 Les Agences de Publicité Ahuntsic Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Quél>ce, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1902, constituant en corporation: Ted«iy Cliadwick, vendeur, 170, Ix'sage, Ste-A«lèle, Lorraine S.Contant, coiffeuse, veuve, et Marguerite Vr.Caouette, infirmière, épouse séparée «le biens «le Jean-Louis Caouette, ces deux dernières de 10120, Place Meilleur, app.11, Montréal, pour les objets suivants: Exercer Ici activités d'entrepreneurs «le publicité et «le conseillers en publicité, sous le nom de « Les Agences «le Publicité Ahuntsic Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 28e jour de décembre 1962./x?Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.2517-o 14893-62 \u2014 1157/138 The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of January, 1963.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.2517 233-63 \u2014 1158/106 I/es Agences de Publicité Ahuntsic Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 28th .lay of December.1962, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>cc, incorporating: Teddy Chad wick, salesman.170 Lesage, Ste-Adèle, Lorraine S.Contant, hairdresser, widow, and Marguerite V.Caouette, nurse, wife separate as to property of Jean-Louis Caouette, the latter two «>f 10120' Place Meilleur.Apt.11, Montreal, for the following purposes: To operate as publicity contractora and councilors, under the name of \"Lea Agences de Publicité Ahuntsic Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of December, 1962.Raymond Dopville, Assistant Secretary of the Province.2517 14893-62 \u2014 1157/138 Alden Realty Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 24e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Samuel David Rudenko, 3980, Côte-des-Neiges, Clarence Reuben Gross, 790, avenue Lexington, tous deux conseils en loi de la Reine, Joel Arnold Pinsky, 4597, avenue Oxford, tous trois avocats, et Sarah Miller, sténographe, fille majeure, 5394, Place Grovehill, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'immeubles et de construction, sous le nom de « Alden Realty Inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureaa du secrétaire de la province, ce 24e jour de janvier 1963.L$ Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.2517 370-63 \u2014 1159/10 Ameublements St-Jean Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Rodolphe Prud'homme, commerçant, Thérèse Patenaude, ménagère, épouse contrac-tuellement séparée de biens dudit Rodolphe Prud'homme, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 429, Baillargeon, et Jean-Denis Davignon, gérant, 369, St-Georges, tous trois de Saint-Jean, pour les objets suivants: Alden Realty Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel David Rutlenko, 3980 Côte-des-Neiges, Clarence Reuben Gross, 790 Lexington Avenue, both Queen's Counsels, Joel Arnold Pinsky, 4597 Oxford Avenue, all three advocates, and Sarah Miller, stenographer, spinster of the full age of majority, 5394 Grovehill Place, all four of Montreal, for the following purposes: To do business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Altlen Realty Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each an«l 900 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of January, 1963.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 370-63 \u2014 1159/10 Ameublements St-Jean Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rodolphe Prud'homme, trader, Thérèse Patenaude, housewife, wife contractually separate as to property of the said Rodolphe Prud'homme, and duly authorized by him for these presents, both of 429 Baillargeon, and Jean-Denis Davignon, manager, 369 St-Georges, all three of Saint Johns, for the following purposes:' 1666 GAZETTE OFF 111 ELU: DE QUEBEC, 6 avril im.Tome 95, No 14 Faire le commerce e at 475 Morin St., Ste-AdèL-en-Hr.ut, judicial district of Terrclxmne.Given at the office of the Provincial Seen tary, this 28th day «>f January, 1963.Raymond Douvii.i.k, Axxixtant Secretary of the Province.2517 396-63 \u2014 1158/108 Audette Express Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en daté du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Rogcr-G.Amlette, gérant, Micheline Audette, secrétaire, Nicole Audette, étudiante garde-malade, toutes deux célibataires majeures, tous trois «le 1717, de l'Église, et Y van Brugge-man, commis 125, Bona venture, tous quatre de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie «le transport, sous le nom de « Audette Express Inc.», avec un capital total de $40,000,' divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire «le la province, «\u2022e 1er jour «le février 1963.lie Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 430-63 \u2014 1158/109 Austro-Canadian Electric Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Quél>ec, «les lettres patentes, en date du 24e jour «le janvier 1963, constituant en corporation: Morris Chaikelson, 5162, rue Isabella, Gregory Charlap, 2990, rue Soissons, tous deux de Montréal, et Max Slapack, 5562, rue Glencrcst, Côte-St-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Audette Express Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger-G.Audette, manager, Micheline Auilette, secretary, Nicole Audette, student nurse, both spinsters of the full age of majority, all three of 1717 de l'Église, and Y van Bruggeman, clerk, 125 Bonaventure, all four of Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Audette Express Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 pre-ferre«l shares of $'00 each.The head office of the company will be at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymon d Dou ville, Axxixtant Secretary of the Province.2517 430-63\u20141158/1C9 Austro-Canadian Electric Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1963.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Morris Chaikelson, 5162 Isabella St., (Jregory Charlap, 2990 Soissons St., both of Montreal, and Max Slapack, 5562 Glencrcst St., Côte-St-Luc, all three advocates, for the following purposes: 1608 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEllEC, 6 avril 1963, Tome 95, No I/, Exercer le commerce «I électriciens, sous le nom ,000, divise en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 455, rue Kugler, Duvernay, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de janvier 1903.Le Sous-secrl'taire de la province, R avmon i) 1 >ou villk.2517 15212-62- 1159/12 Auto-Air leasing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première parti.' de lu Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des li ttres patentes, en date du 1er jour de février 1903, constituant en corporation: Louis G.Kohichaud, 5640, rue Dctvllcs.Montréal, André Bélanger, 020, rue Crevier, St-Laurcnt, et Lmis-Rhéal Tremblay, 43, rue Ritchot, Repentigny.tous trois avocats, poulies objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Auto-Air Leasing Limited ».avec un capital total de $00,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de Ig.compagnie sera 8606, rue Clarke.Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de févri< r 1903.Le Soits-secrttaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o ( 490-03 \u2014 1158/132 To carry on the business of electricians, under the name of \"Austro Canadian Electric Co.Ltd.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares of $10 each ami 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 455 Kuglcr St., Duvernay, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of January, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 15212-62 \u2014 1159/12 Auto-Air Leasing Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the lit day el February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis G.Robiehaud, 5640 Decellcs Street, Montreal, André Bélanger.020 Crcvier Street, St-Laiirent, ami Iiouis-Rhéal Tremblay, 43 Ritchot Street, Repentigny, all three advocates, for the following purposes: To carry on business dealing in automotive vehicles, their accessories and parts and to act as garagemen, under the name of \"Auto-Air Leasing Limited\", with a total capital stock of $00,000, divided Into 1,000 common shares of $10 each anil 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 8005 Clarke Street.Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 490-03- 115S/132 Pierre Auto Location Inc.Avis est tienne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 5e jour de février 1063, constituant en corporation: Paul Gamache, 901, St-Louis, Joliette, Pierre Gamache, II, Ste-Angéline, nord, Joliette, tous deux commerçants, it Rrgcr Perrault, comptable.N« tre-Damc-dcs-Prairies, pour les objets suivants: Faire le commerce «le location «le véhicules automobiles «le tous genres, sous le nom «le « Pierre Ai t < Location Inc.», avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social «le la ccnipagnic sera à Juliette, district judiciaire de Joliette.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «\u2022e 5e jour «le février 1903.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 574-63 \u2014 1159/34 Pierre Auto Location Inc.Notice is hereby given that umicr Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, tearing date the 5th e at 600 Hamel Blvd., shopping Center Fleur-de-Lys, Quebec, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of January, 1963.Raymond Douvillk, - Assistant Secretary of the Province.2517 379-63-1158/111 1674 GAZETTE OFF ICI ELU'.DE QVEliEC.6' avril IMS, Tome ftS, So 11 Ontrul I obu< ( «» Suit's Ltd.Avis t'st donné qu'en vertu tie lu première purtie tie la Loi ties compagnies tie Québec, il a été aeetmlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettrée patentes, en date tlu 22e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Arnold Kustner, administrateur, Fanny Levy Kastner, ménagère, épouse séparée «le biens dtidit Arnold Kastner, et dûment autorisée par ce dernier aux fins ties présentes, tous deux tie 4200, Place Ostell, et Gladys MacLeod, secrétaire, célibataire, 2100, rue Tupper, app.102, tous trois de Montréal, |>our les objets suivants: Exercer le commerce «le marchands «le tabac, sous le nom de « Central Tobacco Sales Ltd.», avec un capital total tic $20,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair tie $1 cheune et 18,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour de janvier 1903.hé Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517 345-03 \u2014 1159/05 Centre Commercial de Repentigny Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de février 1903, constituant en corporation: Luc Parent, avocat, 500, Carlyle, Mont-Royal.Jean Gadbois, avocat, 10, avenue Gren-ville, Westmount, René C.Alary avocat, 3345.McCarthy, St-Laurent, Berthe Lafontaine, 1656.boul.St-Joseph.est, Montréal, et Françoise Lord, 727, Dollard, Longueuil, ces deux «lernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de placements, sous le nom de « Centre Commercial de Repentigny Inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 5.000 actions d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Repentigny, district judiciaire de Joliette.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de frvrier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 673-63\u2014 1159/80 Central Tobacco Sales Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd tlay of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Arnoltl Kastner, executive.Funny Levy Kastner, housewife, wife separate as to property of the saitl Arnoltl Kastner, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 4200 Ostell Place, and Gladys MacLeod, secretary, spinster, 2100 Tupper St., apt.102, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of tobacconists, untler the name of \"Central Tobacco Sales Ltd.\" with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $1 each and 18,000 preferred shares of a par value of $1 each.The heat! office of the company will be at Montreal, judicial tlistrict of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of January, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 345-63\u2014 1159/65 Centre Commercial de Repentigny Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Luc Parent, advocate, 560 Carlyle, Mount Royal, Jean Gadhois, advocate, 10 Grenville Ave., Westmount, René C.Alary, advocate, 3345 McCarthy, St-Laurent.Berthe Lafontaine, 1656 St.Joseph Blvd., East, Montreal, and Françoise Lord, 727 Dollard, Longueuil, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on business as a real estate and investment company, under the name of \"Centre Commercial de Repentigny Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divitled into 5,000 shares of a par value of $10 each.The .head office of the company will ve at Repentigny, judicial district of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 673-63\u2014 1159/80 Les Chaussures Beau-Pied Ltée Beau-Pied Shoes Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 22e jour de janvier 1963, constituant en cor-poration: René Villeneuve, professeur, 54, Gen-tlron, Michael Popowick, technicien, 58, St-François, Bernard Lattion, professeur, 37, Thi-beault, André Gervais.gérant, 49, Gendron, Marcel Boisvenue, inspecteur, 156, Isabelle, tous cinq de Hull.Aurèle Osborne, professeur, 5, Forget, Ste-Rose-dc-Lima, et Hervé Si card, professeur, 638, Watt, Gatincau, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes «le chaussures, articles en cuir et leurs accessoires, sous le nom de « Les Chu us.su res Beau-Pied Ltée \u2014 Les Chaussures Beau-Pied Ltée Beau-Pied Shoes Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: René Villeneuve, professor, 54 Gendron, Michael Popowick, technician, 58 St-François, Bernard Lattion, professor, 37 Thibeault, André Gervais, manager, 49 Gendron, Marcel Boisvenue.inspector, 156 Isabelle, all five of Hull, Aurèle Osborne, professor, 5 Forget, Stc-Rosc-de-Lima, and Hervé Sicard, professor, 638 Watt, Gatineau, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of footwear, leather articles and their accessories, under the name of \"Les Chaussures Beau-Pied QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, urns.Vol.BS, So.14 licau-Picd Shoes Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Hull, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour de janvier 1963.1st Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 14630-62\u20141158/5 la Cie de Construction Cabi (1963) Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Armand Poupart, ch., avocat, 65, avenue Thornton, Mont-Royal, Armand Poupart fils, avocat, 3375, Maplewooert Savard, 33 Range Ste-Geneviève, Lorettcvillc, and Laurent P.Bolduc, advocate, 2056 Ste-Foy Road, Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"La Cic de Navigation «lu (iolfe Ltée \u2014 Gulf Navigation Co.Ltd.\", with a total capital stock of $85,000, divided into 7,500 common shares of $10 each, and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec (iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1963.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.2517 410-63 \u20141158/34 La Cie d'Excavation Lajeunesse Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Guy Godard, avocat, Jacques Duquette, avocat, et Jacqueline Simonneau, secrétaire, fille majeure, tous trois de Ste-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: La Cie d'Excavation Lajeunesse Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governon-of the Province of Quebec, incorporating : Guy Godard, advocate, Jacques Duquette, advocate, and Jacqueline Simonneau, secretary, fille majeure, all three of S te-Agathe-des-Monts, for the following purposes: 1676 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 6 avril 1963, Tome 95, No 14 Exercer It* commerce d'excavateurs, stMis le nom tie « Iai Civ d'Excavation Lajeuncsse Ltée ».avec un capital total tie $20.000.divisé en 2(H) actions ordinaires tie $100 chacune.Ix* siège social tie la compagnie sera à Stc-Agathe-des-Monts.district judiciaire tie Terrebonne.Donné au bureau tin secrétaire «le la province, ce 29c jour tic Janvier 1663.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2r>l7-o 429-03-1158/33 Le Club des Cent Inc.The One Hundred Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi ties compagnies tie Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1903, constituant en corporation: Jean Massicotte, cit., avocat, 670, boni.Désaulnicrs, St-Lambert, Gilles Drouin, directeur général en assurance, 217, Dulwich, St-Lumbert, et Michelle Falardeau, avocat, célibataire majeure, 538, Cherrier, Montréal, pour les objets suivants: Former et diriger un club social, sous le nom tie « Le Club ties Cent Inc.\u2014 The One Hundred Club Inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $200 chacune.Le siège social tie la compagnie sera 89, rue St-Charles, est, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 516-63 \u2014 1159/81 To carry on a business as excavators, under the name of \"Iwi .Cie d'Kxcavation Lajeunesse Ltée\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $100 each.The heat! office of the company will l>e at Ste-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th tlay of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 429-63 1158/33 Le Club des Cent Inc.The One Hundred Club Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean Massicotte, q.c, advocate, 670 Désaulniers Blvd., St-Lambert, Gilles Drouin, general director in insurance, 217 Dulwich, St-Lambert, and Michelle Falardeau, advocate, spinster, 538 Cherrier, Montreal, for the following purposes: To form antl direct a social club, under the name of \"Le Club des Cent Inc.\u2014 The One Hundred Club Inc.\", with a total capital stock of $200,000 divided into 1,000 common shares of $200 each.The head office of the company will be at 89 St-Charles St., East, Longueuil, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.v Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 516-63 \u2014 1159/81 Club Marco Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accortlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Benoit Nadeau, peintre, 147, boul.Montcalm, St-Jean, Gérard Baril, contremaître, Saint-Luc, et Paul Norman-din, barbier, 374 rue St-Jacques, St-Jean, pour les objets suivants: Former et diriger un club social, sous le nom de « Club Marco Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est $10,000.Le siège social de la corporation sera à St-Jean, district judiciaire dTberville.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de février 1963.Ix Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 14892-62 \u2014 1159/23 Club Social des Gourmets de Chandler Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi tics compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, tics lettres patentes, en date du 4e jour de février 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Marc Campbell, restât rateur, Robert Fraser, comptable, et Walter Lévesque, gérant de banque, .oui trois de Chandler, pour les objets suivants: Club Marco Inc.Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital : Benoit Nadeau, painter, 147 Montcalm Blvd., St-John's, Gérard Baril, foreman, Saint-Luc, and Paul Normandin, barber, 374 St-James St., St-John's, for the following purposes: To form and direct a social club, under the name of \"Club Marco Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at St-John's, judicial district of Iberville.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 14892-62 \u2014 1159/23 Club Social des Gourmets de Chandler Notice is hereby given that under Part HI of the Quel>ec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Jean-Marc Campbell, restaurateur, Rol>ert Fraser, accountant, antl Walter Levesque, bank manager, all three of Chandler, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, \\o.//, 1677 (irouper en association toutes les personnes «le Chandler et des environs amateurs de bonne cuisine, sous le nom de « Club Social des Gourmets de Chandler ».Le montant auquel sont limites les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le $10,000.Le siège social de la corporation sera à Chandler, district ju«liciaire «le (îaspé.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, C8 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25! 7-«> 190-63 \u2014 1159/24 To group into an association all the person of Chandler and vicinity amateurs of good cooking, under the name of \"Club Social des Commets «le Chandler\".-The amount to which the value of the immoveable propertv which the corporation may bold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at ('handler, judicial district of (îaspé.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 191)3.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.2517 190-63 \u2014 1159/24 Club Social et Sportif Fais Bien Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 4e jour «le février 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Albert Boucher, employé «le Nap.Gugnon, Thomas St-Pierre, J.-Thomas Lchcl, tous deux secrétaires trésoriers, Romuald Blier, laitier, Joseph Du-mont, comptable, Simon Lord, garagiste, Mau-ri«v Chouinard, télégraphiste, et E\"«l«ly Chouinard, tous huit «le Tourville, comté «le ITsIet, pour les objets suivants: Former et diriger un club sportif, sous le nom de « Club Social et Sportif Fais Bien ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut actpiérir et posséder la corporation, est «le $50,000.\\jC siège social de la corporation sera à Tour-ville, comté de l'Islet, district judiciaire «le Montmagny.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.2517-o 15149-62\u20141159/67 Club Social et Sportif Fais Bien Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Albert Boucher, employee of Nap.Gagnon, Thomas St-Pierre, J.-Thomas Leb I, both secretary-treasurers, Romuald Blier, dairyman.Joseph Dumont, accountant, Simon Lord, garagetnan.Maurice Chouinard, telegraph operator, and Eddy Chouinard, butcher, all eight of Tourville, county of ITslet, for the following purposes: To form and direct a sports club, under the name of \"Club Social et Sportif Fais Bien\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami bold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation will be at Tourville, county of I'lslct.judicial district of Montmagny.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.2517 15149-62 \u2014 1159/67 Colibri Construction Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 25e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Yves St-Arnaud, entrepreneur en construction, 1538, chemin Tiffin, LeMoyne, André Fabien, avocat, 128, avenue De Château-guay, Longueuil, et Madeleine Tessier Lavigne, secrétaire, célibataire, 1616, rue St-Hubert, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Colibri Construction Ltée », avec un capital total de $30,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1538, chemin Tiffin, LeMoyne, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.251 7-o 14547-62 \u2014 1158/36 Colibri Construction Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Yves St-Amand, building contractor, 1538 Tiffin Road, LeMoyne, Ami ré Fabien, advocate, 128 De Châteauguay Ave., Longueuil, and Madeleine Tessier Lavigne, secretary, spinster, 1616 St.Hubert St., Montreal, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Colibri Construction Ltée\", with a total capital stock of $30,000, divided into 200 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 1538 Tiffin Road, LeMoyne, judicial districted Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 14547-62 \u2014 1158/36 Commercial Warehouse Inc.Commercial Warehouse Inc.Entrepot Commercial Inc.Entrepôt Commercial Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, i07h GAZETTE GEE ICI ELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1.%'S, Tome 95, No l >t été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, clés lettres patentes, en e at Dorval, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 6th «lay «if February, 1963.Raymon d Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 589-63 \u2014 1159/88 Dubois Holding Corporation Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu de In première partie de la Loi des compagnies de QuéDee, il a cc, incorporating: Jacques Gaudcttc, Gilles Gaudette, both chartered accountants of 141 Salaberry Street, and Guy Gervais, advocate, 192 Richelieu, all three of St-Johns' for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Dubois Holding Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $36,000, divided into 300 common shares of $1 each and into 3,570 preferred shares of $10 each.The head office of the company will Ik?at Verdun, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 15050-62 \u2014 1158/38 Eastern Floats Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1963, constituant en corporation: James Douglas Fisher, avocat et solliciteur, Lucille Fisher, avocat, épouse séparée de biens dudit James Douglas Fisher, et dûment Eastern Floats Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: James Douglas Fisher, barrister and solicitor, Lucille Fisher, advocate, wife separate as to property of the said James Douglas Fisher, and duly im GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 0 avril IMS, Tome 05, No 14 autorisée par ee dernier aux fins des présentes, tous deux de 542, hlvd (îraham, et Jean Major, ingénieur, 866, avenue Brookficld, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de distributeurs et agents de ventes de flotteurs de vaisseaux aériens ainsi que toutes pièces, assemblages et sous-assemblages d'aéronefs, sous le nom de « Eastern Flouts Ltd.».avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciuire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, raymond Douvillk.2517 385-63\u2014 1159/89 authorized by him for the purpose of these presents, both of 542 (îraham Blvd., and Jean Major, engineer, 360 Brookfield Ave., all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of distributors and sales agents of aircraft floats and also all other parts, assemblies and sub-assembli«>s of aircraft, under the name «>f \"Eastern Floats Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 385-03\u20141159/89 Édifice Montcalm Inc.Montcalm Building Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 25e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Justine Landry, secrétaire, 801, Calixu-Lavalléc, Québec, Denise Nadeau, secrétaire, 802, 8e Avenue, Québec, et Jacques Delisle, avocat, 2031.Richer, Ste-Foy, pour les objets suivants : Acheter ou autrement acquérir, «létenir, posséder à titre de propriétaire, louer, exploiter, transformer, mettre en valeur, améliorer un certain emplacement en la cité de Québec, sous le nom de « Édifice Montcalm Inc.\u2014 Montcalm Building Inc.», avec un capital total de $500,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et en 45,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 2700, boul.Laurier, Ste-Foy, district judiciaire de Québec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 25e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-0 407-63\u2014 1158/73 Edifice Montcalm Inc.Montcalm Building Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Justine Landry, secretary, 861 Calixa-Lavallce, Quebec, Denise Nadeau, secretary, 862, 8th Avenue, Quebec, ami Jacques Delisle, advocate, 2031 Richer, Ste-Foy, for the following purposes: To buy or otherwise acquire, hold, own, rent, operate, transform, develop, improve a certain emplacement in the city of Quebec, under the name of \"Édifice Montcalm Inc.\u2014 Montcalm Building Inc.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $10 each and 45,000 preferred shares of a par value of $10 each.The beat! office of the company will be at 2700 Laurier Blvd., Ste-Foy, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 407-63\u2014 1158/73 Elmwood Steak House Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 4e jour de février 1963, constituant en corporation: George Moshonas, Harry Simatos, tous deux restaurateurs, et Katherine Simatos, secrétaire, fille majeure, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Elmwood Steak House Ltd.», avec un capital total de $2,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 4953, boul.Décarie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-0 539-63 \u2014 1159/90 Les Entreprises Huki Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Elmwood Steak House Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: George Moshonas, Harry Simatos, both restaurant-owners, an«l Katherine Simatos, secretary, spinster of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurant-owners, under the name of \"Elmwood Steak House Ltd.\", with a total capital stock of $2,000, divided into 200 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 4953 Décarie Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 539-63 \u2014 1159/90 Les Entreprises Huki Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, So.14 été accordé, pur le lieutenant - gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Paul Archainhault, notaire, 2040, l»oul.Itosemont, Georges Prenovost, comptable agréé, et Claude Raymond, secrétaire, ces deux derniers de 0505, rue Bordcuux, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le commerce de buandiers, sous le nom de « Lee Entreprises Huki Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires île SI 0 chadune.I.e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 29e jour «le janvier 1903.Le Sous-secrétaire fie la province, Raymond Douvillk.2517-o 471-03\u2014 1158/40 Francoeur Auto Parts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Pierrette Gélinas, 24, rue Johnson, Thérèse Scott, R.R.no 3, et Pierrette Desjardins, 157-D, rue Paré, toutes trois secrétaires, célibataires, «le (îranby, pour les objets suivants: Faire le commerce de moteurs, dynamos, générateurs, piles ou batteries, accumulateurs, tableaux commutateurs, outillages d'éclairage à l'électricité, groupes générateurs d'électricité, moteurs et accessoires électriques de toutes sortes, sous le nom de « Francoeur Auto Parts Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Notre-Dame-des-Laurentides, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 28e jour de janvier 1963.Ia* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 415-63 \u2014 1158/70 bearing date the 29th day of January, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Paul Archambault, notary, 20-10 Roseinount Blvd., Georges Prenovost, churtcred accountant, an«l Claude Raymond, secretary, the latter two of 0505 Bordeaux St., all three of Montreal, for the following purposes: To operate a business as lauuderers, under the name of \"Lei Entreprises Huki Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial ee Companies Act, letters [latent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Harvey, plasterer, 285, 53rd St.West, Charlesbourg, Claude Simard, plasterer, 10 Vcrret St., Notre-Dame-des-Laurentides, and Claude Royer, notary, 2785 Poitiers St., Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business as contractors-plasterers, under the name of \"Harvey & Simard Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 285, 53rd St.West, Charlesbourg, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 482-63 \u2014 1159/29 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1063, Vol, 05, So.14 1680 Hôtel Richelieu Motel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 19G3, constituant en corporation : Bernard Gardner, 412, chemin Northcote, Rosemère, Gabriel Glazer, 5850, ave., Souart, Hilliard Ginsberg, 3459, rue Drumraond, tous trois avocats, et Anne Zifkin, secrétaire, fille majeure, 4840, rue Bourret, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'hôteliers, sous le nom de « Hôtel Richelieu Motel Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 500 actions privilégiées de $10 chucune.Le siège social de la compagnie sera 1114, première Rue, Richelieu, district judiciaire de St-Hyacinthe.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de janvier 19G3.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.2517 390-63 \u2014 1159/32 Hôtel Richelieu Motel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard GunIner, 412 Northcote Rd., Rosemère, Gabriel Glazer, 5850 Souart Ave., Hilliard Ginsberg, 3459 Drummond St., all three advocates, and Anne Zifkin, secretary, spinster of the full age of majority, 4840 Bourret St., the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of inn-kee|>cr8, under the name of \"Hôtel Richelieu Motel Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of $10 each and 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 1114 First Street, Richelieu, judicial district of St-Hyacinthe.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 390-63 \u2014 1159/32 Hy Fashions Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Henry L.Silverstone, Stanley Goldncr et Allan B.Frank, avocats, de 4 est, rue Notre-Dame, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements, sous le nom de « Hy Fashions Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chucune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 509-63\u20141158/79 Hy Fashions Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Henry L.Silverstone, Stanley Goldner and Allan B.Frank, advocates, of 4 Notre-Dame Street East, Montreal, for the following purposes: To deal in wearing apparel, under the name of \"Hy Fashions Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each ami 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office qf the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 509-63 \u2014 1158/79 I/C.s Immeubles des Chutes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Robert Légaré, 15, rue Louis-Francoeur, Cap-Rouge, Guy Boutet, 1090, Villebon.Québec, tous deux professeurs de golf, Gérard Bureau, 25, d'Artois, Courville, et Angenor Bolduc, 21, Mercier, Courville, ces deux derniers constructeurs, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Les Immeubles des Chutes Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15, rue Louis-Francoeur, Cap-Rouge, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-q 337-63 \u2014 1158/80 Les Immeubles des Chutes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert Légaré, 15 Louis-Francoeur, Cap-Rouge, Guy Boutct, 1090 Villebon, Quebec, both golf professors, Gérard Bureau, 25 d'Artois, Courville, and Angenor Bolduc, 21 Mercier, Courville, the latter two builders, for the following purposes: To carry on business in the field of real estate and construction, under the name of \"Les Immeubles des Chutes Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 15 Louis-Francoeur Street, Cap-Rouge, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 337-63 \u2014 1158/80 1686 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 0 avril 1903, Tome 95, So 14 Les liiinii iililcs ï{\\\\ici c-au\\-Pins Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 5e jour de février 1963, constituant en corporation: Clovis Langlois, homme d'affaires, 54, avenue De Caumont, Nestor Deshaies, constructeur, SS, boul.de Varennes.et Jérôme Comeau, constructeur.753, Pierre-l'ioher, tous trois de Boucherville, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de l'immeuble de la construction, sous le nom de « Les Immeubles Rivière-aux-Pins Inc.», avec un capital total de $80,000, divisé en 800 actions ordinaires de $10 chacune et en 720 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Boucher-ville, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 15049-62\u20141159/95 Imprimerie-Librairie Côté Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Laurent Côté, imprimeur, Mme Marie Beaulieu Côté, ménagère, épouse commune en biens dudit Luurent Côté, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de Hauterive, et Sarto Cloutier, avocat, Baic-Comeau, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'imprimeurs, graveurs, relieurs et autres commerces semblables, sous le nom de « Imprimerie-Librairie Côté Limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $25 chacune et en 1,200 actions privilégiées de $25 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Haute-rive, district judiciaire de Saguenay.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 459-63\u2014 1158/81 I.e.- Immeubles Rivicre-aux-Pins Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Clovis Langlois, businessman, 54 De Caumont, Ave., Nestor Deshaics, builder, 88 de Varennes Blvd., and Jérôme Comeau, builder, 753 Pierre-Picher, all three of Boucherville, for the following purposes : To carry on business in the fields of real estate and construction, under the name of \"Les Immeubles Rivière-aux-Pins Inc.\", with a total capital stock of $80,000.divided iido 800 common shares of $10 each ami 720 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Boucherville, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Proviiwe.2517 15049-62 \u20141159/95 Imprimerie-Librairie Côte Limitée Notice is hereby given that under Part I o the Quebec Companies Act, letters patent' bearing date the 30th day of January, 1963' have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Laurent Côté, printer, Mrs.Marie Beaulieu Côté, housewife, wife common as to property of the said Laurent Côté, and duly authorized by him for these presents, both of Hauterive, and Sarto Cloutier, advocate, Baie-Comeau, for the following purposes: To carry on a business as printers, engravers, binders, and other similar businesses, under the name of \"Imprimerie-Librairie Côté Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $25 each and into 1,200 preferred shares of $25 each.The head office of the company will be at Hauterive, judicial district of Saguenay.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 459-63\u20141158/81 Les Industries St-Gabriel Inc.Les Industries St-Gabricl Inc.St.Gabriel Industries Inc.St.Gabriel Industries Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Quebec, il a été accor«lé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres pat entes, en «late du 21e jour «le janvier 1963, constituant en corporation: Anatole Cou tu, cultivateur, J.-B.-Alphonse Cotlttt, menuisier, et Gaston Vassart, vendeur, tous trois de St-Gahricl-dc-Brandon, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le constructeurs et d'entrepreneurs généraux en const r îction, sous le nom de « Les Industries S t-G a uriel Inc.\u2014St.Gabriel Industries Inc, », avec un capital total de $27,000, divisé en 270 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Ga-briebde Brandon, district judiciaire de Joliette.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 21e jour «le janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 325-63\u2014 1158/48 Notice is hereby given that under Partf I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporai in g : Anatole Coutil, farmer, J.-B.-Alphonse Coutu, joiner, and Gaston Vassart, salesman, all three of St-Gabriel-de-Bfandon, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Les Industries St-Gabricl Inc.\u2014 St.Gabriel Industries Inc.\", with a total capital stock of $27,000, divided into 270 common shares of $100 each.The head office of the company will l>e at St-Gabriel-dc-Brandon, judicial district of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 325-63\u20141158/48 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1063, Vol.05, So.11 1«s7 Inter State Paving Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Lui des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1903, constituant en cor-poration: Pietro Rizz.it n, (îiuseppe Kizzuto, tous «leux de 7305, Cartier, Alfonso Rizzuto, Antonio Rizzuto et Filippo Rizzuto, ces trois derniers «le 7303, Bordeaux, tous cinq imlustriels, de Montréal, pour les objets suivants : Faire «lu pavage et exercer le commerce de marchands «le pierre, sous le nom «le « Inter Stute Paving Inc.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 600 actions ordinaires de $100 chacune et en 400 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 2125, Jean-Talon, est, suite 5, Montréal, district judi-«\u2022iaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour «le janvier 1903.Ia* Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 472-03\u2014 1158/82 Jeunette Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Quel .ce, il a été accor«lé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Stanley Golberg, comptable agréé, 453, 96 rue, Chomedey, Sidney Cutler, avocat, 6255, Place Northcrest, app.402, et Edward Druker, étudiant en droit, 5255, chemin Côte St-Luc, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements pour dames, sous le nom de « Jeunette Inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune et 700 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 421-63\u2014 1158/49 Inter State Paving Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 30th «lay of January, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pietro Rizzuto, Giuseppe Rizzuto, both of 7305 ('artier, Alphonso Rizzuto, Antonio Rizzuto und Filippo Rizzuto, the last three of 7303 Bordeaux, all five industrialists, of Montreal, for the following purposes: To do paving and to carry on business as stone merchants, under the name of \"Inter State Paving Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 000 common shares of $100 each ami into 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 2125 Jean-Talon.East, suite 5, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of January, 1068.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 472-03\u2014 1158/82 Jeunette Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 28th day of January, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Stanley Golberg, chartered accountant, 453, 96th Street, Chomedey, Sidney Cutler, advocate, 6255 North-crest Place, Apt.402, and E«lward Druker, law-student, 5255 Côte St-Luc Rd., the latter two of Montreal, for the following purposes: To deal in women's wearing apparel, under the name of \"Jeunette Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 300 common shares of $10 each and 700 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of January, 1963.RaymondJDouvillk, Assistant Secretarylof the Province.2517-o 421-63 \u2014 1158/49 Kane Bros Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late «lu 21e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Samuel Godinsky, en., 731, Upper Bel-mont, Westmount, Reuben Resin, 5510, Robinson, Côté-St-Luc, Joseph S.Blumer, 5053, ave.Ponsard, et Michael (i.Grecnblatt, cit., 1745, avenue des Cèdres, ces deux derniers de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce d'encadrements, statues, gravures et de tous genres et descriptions d'articles de nouveauté, sous le nom de « Kane Bros Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 21e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 330-63 \u2014 1158/50 Kane Bros Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Queliec, incorporating: Samuel Godinsky, Q.c., 731 Upper Belmont, Westmount, Reuben Resin, 5510 Robinson, Côte-St-Luc, Joseph S.Blumer, 5053 Ponsard Ave., and Michael G.Greenblatt, q.c, 1745 Cedar, Ave., the latter two of Montreal, all four a«lvocates, for the following purposes: To deal in picture frames, statues, pictures and novelties of every type or description, under the name of \"Kane Bros fnc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of à par value of $100 each ami 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of January, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 330-63 \u2014 1158/50 1688 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1963, Tome 95, No 14 G.i.aliaic Inc.Avis eft donné qu'en vertu de la première partie de lu Lui des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour de février 1963, constituant en corporation : Jacques Guérin, avocat, 193, boul.Beaconsfield, Beaconsfield, André Hrunet, avocat, 8525, rue Waverlcy, Montréal, et Gaé-tane Richer, sténographe, fille majeure, 5603, avenue Coolbrook, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers restaurateurs, sous le nom de « (1.La haie Inc.», avec un capital total de $25,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 240 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Pointe-Claire, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 13417-62\u2014 1159/33 La Paix dan* la Montagne lue.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Lucien Arcand, industriel, 175, rue Perreault, Gaston Beau-chesne, industriel, 353, rue Laurier, et Roger Lussier, journaliste.416, rue Laurier, tous trois de Victoriaville, pour les objets suivants: Former et diriger un club sportif, sous le nom de « La Paix dans la Montagne Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Artha-baska, district judiciaire d'Arthabaska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.2517-o 512-63 \u2014 1159/102 Lecar Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1963, constituant en cor-ration: Clément Let arte, industriel, Adrien tarte, expéditeur, et Roch Letarte, expéditeur, tous trois de Warwick, pour les objets suivants: Exercer les opérations d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Lecar Ltée », avec un capital total de $400,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $5 chacune, 975 actions privilégiées classe I A » de $200 chacune et en 40,000 actions privilégiées classe « B » de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Warwick, district judiciaire d'Arthabaska.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-0 362-63 \u2014 1159/1 G.Lahaie Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Guérin, advocate, 193 Beaconsfield, Blvd., Heaconsfield, André Brunet, advocate, 8525 Waverley, Montreal, and Gaétane Richer, stenographer, fille majeure, 5603 Coolbrook Ave., Montreal, for the following purposes: To carry on as grocers, restaurateurs, under the name of \"G.Lahaie Inc.\", with a total capital stock of $25,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 240 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 13417-62 \u2014 1159/33 La Paix dans la Montagne Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Lucien Arcand, industrialist, 175 Pcrreault St., Gaston Beauchesne, industrialist, 353 Laurier St., and Roger Lussier, journalist, 416 Laurier St., all three of Victoriaville, for the following purposes: To form and direct a sports club, under the name of \"La Paix dans la Montagne Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation will be at Arthahaska, judicial district of Arthabaska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 512-63 \u2014 1159/102 Lecar Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Clément Letarte, industrialist, Adrien Letarte, shipper, and Roch Letarte.shipper, all three of Warwick, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Lecar Ltée\", with a total capital stock of $400,000, divided into 1,000 common shares of $5 each, 975 preferred class \"A\" shares of $200 each and 40,000 preferred class \"B\" shares of $5 each.The head office of the company will be at Warwick, judicial district of Arthabaska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 362-63 \u2014 1159/1 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, IMS, Vol.99.So./.; 1689 La Ligue des Contribuables de Longueuil Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 24e jour de janvier 1963, constituant en corporation sans capital-actions: Dr Georges ( \"barest, médecin, 222, lomoyne, Gaétan Haillar-geon, chef de tirage, 118, d'Anjou, Ivan A.Lcgault, secrétaire exécutif, 447, Quinn, Géruld U.Guérin, courtier en immeubles, 179, La bonté, Paul Martel, gérant de bureau, 289, De Lorraine, Jean-L.Rameau, secrétaire administratif, 407, Labonté, .1.-Alphonse Côté, acheteur.169, chemin Chamhly, Dr Edouard-Henri Letellier, médecin, 149, St-Laurent, Olivier R.Duvernay, marchand, 143, St-Thomas, et Jacques Roux, assureur-vie, 242, St-Alexandre, tous dix de Longueuil, pour les objets suivunts: Grouper en associai ion les contribuables de la cité de Longueuil, sous le nom de « La Ligue des Contribuables de Longueuil m.Le montant a.iqucl sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et passé der, est de $5,000.Le siège social de la corporation sera à longueuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de janvier 1963.Le Sotie secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.2517-o 307-63 \u2014 1157/129 Marché St.Louis Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première purtie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 5e jour de février 1963, constituant en corporation: Jean-Claude Mondou, entrepreneur, 156, Mgr-Prévost, St-Eustachc, Dollard Théoret, boucher, 175, Bellerive, St-Eustache, et Gilles Grenier, comptable agréé, 1395, rue Flcury, est, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'épiciers-bouchers, sous le nom de f Marché St.Louis Inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 77, me St-Louis, St-Eustache, «listrict judiciaire «le Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 5e jour de février 1963.1a Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.2517-o 571-63\u20141159/2 La Ligue des Contribuables de longueuil Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 24th day of Jun lary, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corpo-ration without share capital: Dr.Georges Clia-rest, physician, 222 Lcnioync, Gaétant Baillar-geaon, head of impression department, 118 «l'Anjou, Ivan A.Lcgault, executive secretary, 447 Quinn, Gérald V, Guérin, real estate broker, 179 Labonté', Paul Martel, office manager, 289 De lorraine, Jean-L.Rameau, administrative secretary, 407 Labonté, J.-Alphonse Côté, buyer, 169 Chamhly Road, Dr.Édouanl-Henri Letellier, physician, 149 St-Laurent, Olivier R.Duvernay, merchant, 143 St-Thomas, and Jacques Roux, life insurer, 242 St-Alexandre, all ten of Longueuil, for the followig purposes: To group together into an association the tax-payers in the city of longueuil, under the name of \"La Ligue des Contribuables de longueuil\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation acquire ami may hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation will be at Longueuil, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 367-63 \u2014 1157/129 Marché St.Louis Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean-Claude Mondou, contractor, 156 Mgr.-Prévost, St-Eustache, Dollard Théoret, butcher, 175 BcJlerive, St-Eustache, and Gilles Grenier, chartered accountant, 1395 Fleury St., East, Montreal, for the following purposes: To operate a business as grocers-butchers, under the name of \"Marché St.Louis Inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at 77 St-Lou is St., St-Eustache, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 571-63 \u2014 1159/2 Nasa Enterprises Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er j«>ur de février 1963, constituant en corporation: Dr Arnold Grossman, Dr.Nyla Lines Grossman, épouse séparée de biens dudit Arnold Grossman, et dûment autorisée par ce «lernier aux fins des présentes, tous «Jeux médecins, de 122, avenue Lockhart, Mont Royal, et Satil Grossman, manufacturier, 5718, cchmin Queen Mary, Hampstead, pour les objets suivants: Exercer le commerce de vêtements et de textiles, sous le nom de « Nasa Enterprises Naaa Enterprises Incorporated Notice is hereby given that under Part I of the Qucl)ec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Dr.Arnold Grossman, Dr.Nyla Eines Grossman, wife separate as to property of the sai«l Arnold Grossman, and duly authorized by him for the purpose of these presents, both medical doctors, of 122 Lockhart Ave., Mount Royal, and Salll Grossman, manufacturer, 5718 Queen Mary Rd., Hampstead, for the following pump ses: To deal in wearing apparel and textiles, under the name of \"Nasa Enterprises Incorporated\", 1800 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, Tome 95, No H Incorporated ».avec un capital total de $40,000, divisé en 1,(0') actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 cliaciinc et .'{.(MM) actions privilégiées d'une valeur au pair de .$10 chacune.Is siège SOCtaJ tie la compagnie sera à Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 1er jour de février 100.'!.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 514-03\u2014 1159/0 with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 coi n mon shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office «»f the company will Ik?at Montreal, judicial district of Montreal.Ciiven at the office of the Provincial Secretaiy.this 1st day of February, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 514-03\u20141159/6 P.& D.Transport Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le lu province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 18e jour de février 1903, constituant en corporation: Léonartl Bergeron, avocat, Etienne Dus-sault, notaire, tous deux de 209, rue Main, ouest, et Lise Vaillancourt.secrétaire, 2, rue St-Patricc, est, tous trois «le Magog, pour les objets suivants : Exercer le commerce d'une compagnie «le transport, sous le nom «le « P.& D.Transport Inc.», avec un capital total «le $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaire» de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, «listrict judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 18e jour «le février 1903.Le Sou*-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.8817-0 753-63\u20141159/109 Pacific Fur Company Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il u été accortlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres pat en tes, en «late du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Seymour Machlovitch, 3445, chemin de la Côtc-«les-Neiges, Adolphe Gardner, ch., 4200 ouest, rue Sherbrooke, tous deux de Montréal, Jack Shayne, 5781, ave.M el ling, tous trois avocats, et Mavis Mcldrum, secrétaire, épouse séparée de biens de Gordon Meldrum, 5626, ave.Emerald, ces deux derniers «le CV>te-St-Luc, pour les objets suivants: Faire le commerce «le fourrures et peaux «le fourrure, sous le nom «le « Pacific Fur Company », avec un capital total «le $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau d.i secrétaire de la province, ce 1er jour «le février 1963.Ia: Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 481-63 \u2014 1159/8 P.& D.Transport Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 18th «lay of February, 1963, have l)eeii issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Léonard Bergeron, advocate, Etienne DussaulL notary, loth of 269 Main St.West, ami Lise Vaillancourt, secretary, 2 St-Patricc St.Fast, all three of Magog, fur the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"P.& D.Transport Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The bead office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Given at the oflicc of the Provincial Secretary, this 18th day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 753-63\u2014 1159/109 Pacific Fur Company Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1 st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Seymour Machlovitch, 3445 Côte-des-Ncigcs Road, Adolphe Gardner, q.c, 4200 Sherbrooke St.West, both of Montreal, Jack Shayne, 5781 Melling Ave., all three av«loeates, antl Mavis Meldrum, secretary, wife separate as to property of Gordon Meldrum, 5626 Emerald Ave., the latter two of Côte-St-Luc, for the following purposes: To deal in furs and fur skins, under the name of \"Pacific Fur Company\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,(00 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 481-63 \u2014 1159/8 R.Panneton Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 4e jour «le février 1963, constituant en corporation: Paul Arehambault, notaire, 2040, boul.Rosemont, Georges Prénovost, comptable agréé, et Claudette Raymond, secrétaire, ces deux derniers de 6505, rue Bordeaux, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: R.Panneton Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th day of February, 1963, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>cc, incorporating: Paul Arehambault, notary, 2040 Rosemont Blvd., Georges Prénovost, chartered accountant, and Claudette Raymond, secretary, the latter two of 6505 Bordeaux St., all three of Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1.968, Vol.95, No.U ni! m Exercer le commerce d'entrepreneurs électriciens, sous |e nom «le « It.Hanneton Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à St-Laurent, district jiuliciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ee 4e jour «le février 1963.Ias Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 543-63\u2014 1159/9 To carry on business as contractors-electricians, under the name of \"R.Panneton Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head oliie ¦ of the company will he at St Laurent, judicial distritt of Montreal.(Jiven at the 0008 of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1968.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 843-68 U59/9 Papineau Musique Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la loi des compagnies de Quebec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour «le février 1963, constituant en corporation: André Let)son, avocat, 8353.rue Drolet, M« ni«p e Rjulino, secrétaire, épouse séparée de biens de Vincenzo Radino, 3435, rue Frontenac, et Astrid Pelletier, secrétaire, fille majeure et usant «le SCS droite, 6914, Wiseman, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce et la réparation d'appareils «le radio, «le télévision, accessoires électriques, instruments «le musique, leurs parties et accessoires, et autres marchandises semblables, sous le nom de « Papineau Musique Ltée ».avic un capital total «le $40.000.divisé en 40,000 actions ordinaires «le $1 chacune.I.c siège social de la.compagnie sera 206, rue Jarry, est, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de février 1963.Le Sous-secretaire de la province, Raymond Douville.2517-o 467-63 1158/120 Papineau Musique Ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: André Lauaon, advocate, S353 Droh t St., Monique Hadino, secretary, wife separate as to property of Vmcenao Radino, 3435 Frontenac St., and Astrid Pelletier, secretary, fille majeure et usant tic ses droits, 6914 Wiseman, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business dealing in antl repairing ratlios, televisions, electrical accessories, musical instruments, their parts antl accessories, and other similar merchandise, under the name of \"Papineau Musique Ltée*', with a total capital stock of $40.000, divided into 40.000 common shares of 81 each.The head office of the company will be at 200 Jarry St.East, Montreal, judicial district »f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 \" 407-03 \u2014 1158/120 Les Placements de Dolbcau Limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 14e jour de février 1963, constituant en corporation: André Blanchet, avocat, Ghislaine Caron, secrétaire, célibataire majeure, et Ghislain Marcoux, agent d'assurances, tous trois de Dolbcau, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Les Placements «le Dolbeau Limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 550 actions ordinaires «le $10 chacune et en 3,450 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 541, boul.Walberg, Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 728-63 \u2014 1160/48 Les Placements de Dolbeau Limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1963, have been issued by the Ljeutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: André Blanchet, advocate, Ghislaine Caron, secretary, spinster, and Ghislain Marcoux, insurance agent, all three of Dolbeau, for the following purposes: To operate a company as an investment company, under the name of \"Les Placements de Dolbeau Limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 550 common shares of $10 each antl into 3,450 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 541 Walberg Blvd., Dolbeau, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 728-63\u2014 1160/48 Les Placements Hell aria Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu[24e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Sergio Tucci, avocat, Sebastiana Marino, ménagère, veuve non remariée de Raffaele Mari- Les Placements ht Maria Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Sergio Tucci, advocate, Sebastiana Marino, housewife, unremarried widow of Raffaele Marino, both of 1092 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEllEC, 6 avril IMS.Tome 95, No H no, tous deux de 6702, boul.St-Laurent, Luigi Alhanese, avocut stagiaire, 7617, De Norman-ville, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom de « Les Placements Bellaria Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1469, De Salahcrry, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2617-0 14872-62 \u2014 1158/59 Plomberie & Chauffage Cartier Inc.Cartier Plumbing & Heating Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1963, constituant en corporation: Bernard Nantel, 17, avenue Bcllcvue, Westmount, André Surprenant, 573, Montenuch, Beloeil, et Maurice Mercure, 1581, Norway, Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneurs en plomberie, chauffage et réfrigération, sous le nom de « Plomberie & Chauffage Cartier Inc.\u2014 Cartier Plumbing & Heating Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège sociul de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 456-63 \u2014 1158/89 6702 St-Lawrencc Blvd., Luigi Alhanese, law student, 7617 De Normanvillc, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Bellaria Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 shares of $10 each.The head office of the company will be at 1469 De Salaberry, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of January, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 14872-62\u2014 1158/59 Plomberie & Chauffage Cartier Inc.Cartier Plumbing & Heating Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard Nantel, 17 Bellevue Ave., Westmount, André Surprenant, 573 Montenach, Bcloeil, and Maurice Mercure, 1581 Norway, Mount-Royal, all three advocates, for the following purposes: To operate a business us contractors in plumbing, heating and refrigeration, under the name of \"Plomberie & Chauffage Cartier Inc.\u2014 Cartier Plumbing & Heating Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 456-63 \u2014 1158/89 Poly-Glot (1963) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 4c jour de février 1963, constituant en corporation: Se vérin La chape lie.avocat, 52, Place Beaumont, Ste-Foy, Claire Racine, secrétaire, fille majeure, 5457, avenue Royale, Bois-chatcl, et Jacqueline Gamache, secrétaire, fille majeure, 134, Rochette, Ste-Foy, pour les objets suivants: Faire le commerce de disques, livres, gravures et autre médium d'information pour des fins éducatives, de divertissements et autres, sous le nom de « Poly-Glot (1963) Inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-0 551-63\u20141159/35 Poly-Glot (1963) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1963, have been issued by the Liutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Séve-rin Lachapelle, advocate, 52 Place Beaumont, Ste-Foy, Claire Racine, secretary, fille majeure, 5457 Royale Ave., Boischatel, and Jacqueline Gamache, secretary, fille majeure, 134 Rochette, Ste-Foy, for the following purposes: To carry on business dealing in records, books, engravings and other media of information for educational, recreational and other purposes, under the name of \"Poly-Glot (1963) Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $10 each.The head office of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at ths office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 551-63 \u20141159/36 Prestige Construction Ltée Prestige Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Prestige Construction Ltée Prestige Construction Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.96, So.14 1093 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 1er jour de février 1963, constituant en corporation: Albert Rodrigue, constructeur, 15470, M oisc h a te], André Théoret, industriel, 15447, Boischatel, tous deux de Pierrefonds, et Pierre l'a te nam le, comptable, 29, 14e rue, Roxboro, pour les objets suivants: Faire affaires dans les domaines de rimmedhie et de la construction, sous le nom de s Prestige Construction Ltée \u2014 Prestige Construction Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 15757, lioulevanl Gmiin, ouest, Ste-Geneviève, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour «le février 1963.Lt Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 463-63 \u2014 1158/121 Les Productions Ci né-Jeunes Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieu tenu nt-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 6e jour «le février 1963, constituant en corporation: Gilles Boisvert, huissier, 5744, Delori-mier, Montréal, Roger Laliberté, technicien, 6840, DcLaroche, Montréal, et Nicole Mathieu, secrétaire, fille majeure, 1452, Bishop app.5A, Montréal, pour les objets suivants: Réaliser «les films et «les émissions, de tous genres, destinés tant à la radio qu'à la télévision ou aux salles de cinéma ou à tout autre groupement ou association, sous le nom de « Les Productions Ciné-Jeunes lue.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 6e jour de février 1963.lœ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 250-63 \u2014 1159/104 Produits Alba Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première parti) «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été jee rdé, par le lieutenant-gouverneur de la proviso de Qrébec, «l-s lettres patentes, en date «lt! 25e jour «le janvier 1963, constituant en corporation: Dr Gérard Tartlif, chirurgien den-distc, 665, bout Wulherg, Dolbeau, Joseph Bergeron, conseiller en assurance, 82, boul.Walberg, Dolbeau, et Robert Maltais, gérant, Aima, pour les objets suivante: Commerce de tors produits provenant des agrégats de calcite ou autres produits provenant du sol, SOUS le nom de « Produits Alba Inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 5,000 acti< ns privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de $10 chacune et en 500 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège sccial de la compagnie sera à Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-o 408-63\u20141159/36 bearing date the 1st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Rodrigue, builder, 15470, Boischatel, André Théoret, industrialist, 15447 Boischatel, both of Pierrefonds, and Pierre Patenaude, accountant, 29, 14th Street, Roxboro, for the following purposes: To carry on business in the field of real estate and construction, under the name of \"Prestige Construction Ltée \u2014 Prestige Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20.0C0 common shares of $1 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 15757 Gouin Boulevard, West, Ste-Geneviève, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 463-63 -1158/121 Les Productions Ciné-Jeunes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Boisvert, bailiff, 5744 Delorimier, Montreal, Roger Laliberté, technician, 6840 DcLaroehe, Montreal, and Nicole Mathieu, secretary, fille majeure, 1452 Bishop, apt.5A, Montreal, for the following purposes: To produce 61ms and programs of all kinds, destined for radio as well as for television or theatres or any other group or association, under the name of \"Les Productions Ciné-Jeunes Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 250-63\u20141159/104 Produits Alba Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of January, 1963, have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gérard Tardif, dental surgeon, 665 Walberg Blvd., Dolbeau, Joseph Bergeron, insurance counsellor, 82, Walberg Blvd., Dolbeau, and Robert Maltais, manager, Alma, for the following purposes: To operate a business dealing in all products derived from the agregate of calcite or other products from the soil, under the name of \"Produits Alba Inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $10 each, 5,000 preferred shares class \"A\" of a par value of $10 each and into 500 preferred shares class \"B\" of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Dolbeau, judicial district of Roberval.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 408-63 \u2014 1159/36 1694 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1063, Tome 05, So 14 Kadi-Air Inc.Avis est donné qu'on vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quéltec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1903, constituant en corporation: Maurice Bcaudtt.industriel, 1914.Bourbonnière, Sillcry, Charlcs-11.Biais, ingénieur professionnel, 1215, Brnest-Lnvigne, Sillcry, et Roland Godbout, comptable, 340, 10c rue, Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « ltadi-Air Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 400 actions «le Sl(M) chacune.Le siège s«:cial de la compagnie sera S77, boul.('barest, est, Québec, «listrict judiciaire de Québec.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, Ce 30e jour de janvier 1963.Le Sou-s-sccrétaire de la province, Raymond Douville, 2517 o 457-63\u2014 1158/122 Radi-Air Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec; Companies Act, letters patent, bearing date the 30th ec Com'anies Act, letters patent, bearing date the 24th «lay «)f January, 1963, 1700 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, a avril 1998, Tome 98, No H province de Québec, des lt ttres patentes, en date du 24c jour de janvier 1968.constituant en corporation: Roger Lalongé, pompier, 0S25, Mcrritt, Stella I.alougé, ménagère, épouse séparée de biens dudit Roger Lalongé, 9K25, Mcrritt, et Vianncy Lalongé, chauffeur d'autobus, 10625, Verville, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de matériaux de vitrerie, sous le nom de « Vitrerie Lalongé Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chrome et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 9825, rue Mcrritt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Dorure au bureau du secrétaire de la province, ce 24e jour de janvier 1903.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-q 381-03 \u2014 1158/103 Westmount Draperies Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 6e jour de février 1963, constituant en corporation: Harold Asbenmil, Julien Kotlcr, et Jon Kosorwicb, avocat, de 901, rue Blcury, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le tentures, rideaux, abat-jour, stores, draperies, tapisserie d'ameublement, sous le nom de « Westmount Draperies Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «le $100 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 6e jour «le février 1963.Lô Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517 587-63 \u2014 1159/113 have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Lalongé, fireman, 0626 Mcrritt, Stella Lalongé, housewife, wife separate us to property of the said Roger Lalongé, 9825 Mcrritt am! Vianney Lalongé, chauffeur for an autobus, 10625 Verville, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on a business dealing in all kinds of materials of glass, under the name of \"Vitrerie Lalongé Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 9825 Mcrritt St., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, is 24th «lay of January, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 381-63 \u2014 1158/103 Westmount Draperies Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Gompanies Act, letters patent, bearing «late the 6th day of February, 1963, have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Harold Ashen m il, Julian Kothr and Jon Kosorwich, a«lvocatcs, of 901 Blcury Street, Montreal, for the following purposes: To deal in drapes, curtains, shades, blinds, hagings and upholstering, under the name of \"Westmount Draperies Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will 1m?at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-0 587-63\u2014 1159/113 Yamel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 29e jour «le janvier 1963, constituant en corporation: Fernand Lemay, arpenteur géomètre, Charlotte Mathieu Lemay, ménagère, épouse séparée de biens «lu«lit Fernand Lemay, tous deux de 902, avenue Victoria, St-Lambert, et Pierre Leprohon, clerc arpenteur, 1910, boul.St-Joseph, est, Montréal, pour les objets suivants : Faire affaires dans les domaines «le l'immeuble et de la construction, sous le nom de « Yamel Inc.», avec un capital total «le $37,000, divise en 200 actions ordinaires de $10 chacune et en 350 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montreal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 29e jour de janvier 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-q 413-63 \u2014 1158/105 Yamel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing dute the 29th day of January, 1963.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Fernand Lemay, surveyor, Charlotte Mathieu Lemay, housewife, wife separate as to property of the said Fernand Lemay, both of 902 Victoria Ave., St-Lambert, ami Pierre Leprohon, surveying clerk, 1910 St-Joseph Blvd., East, Montreal, for the following purposes: To curry on business in the field of real estate and construction, under the name of \"Yamel Inc.\", with a total capital stock of $37,000, divided into 200 common shares of $10 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 413-63- 1158/105 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 0, 1903.Vol.95, So.14 1701 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Association Provinciale des Constructeurs d'Habitation* du Québec Inc.Quebec Provincial Home Builders Association Inc.Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 14 février 1903, à la corporation « Association Provinciale des Constructeurs du District de Québec Inc.\u2014 Quebec Provincial Home Builders Association Inc.», constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite Loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 6 décembre 1962, changeant son nom en celui de «Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec Inc.\u2014 Quebec Provincial Home Builders Association Inc.».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 14918-62 \u2014 1160/1 Canadian Insurance Claims Service Corporation Service Canadien d'Évaluation de Sinistres Inc.Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec Inc.Quebec Provincial Home Builders Association Inc.Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Association Provinciale des 'Constructeurs du District de Québec Inc.\u2014 Quebec Provincial Home Builders Association Inc.\", incorporated under the provisions of Part III of the said Quebec Companies Act, by letters patent dated December 6, 1962.changing its name to \"Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec Inc.\u2014 Quebec Provincial Home Builders Association Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of February.1963.R a y m on d dou vi 1.1.1., Assistant Secretary of the Province.2517 14918-62 1160/1 Canadian Insurance Claims Service Corporation Service Canadien d'Évaluation de Sinistres Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 5 février 1963, à la compagnie « Canadian Insurance Claims Service Corp.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 22 juillet 1954, changeant son nom en celui de « Canadian Insurance Claims Service Corporation \u2014 Service Canadien d'Évaluation de Sinistres Inc.».Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 5 février 1963./ai Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 11610-54 \u2014 1159,17 Chalet Barb-Q Incorporée Chalet Barb-Q Incorporated Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 0 février 1963, à la compagnie « Chalet Barb-Q Incorporée \u2014 Chalet Barb-Q Incorporated », 10 subdivisant ses 500 actions ordinaires de $100 chacune en 50,000 actions ordinaires de $1 chacune; 2° subdivisant ses 600 actions privilégiées «le $100 chacune en 60,000 actions privilégiées de $1 chacune; 3e convertissant 40,000 actions ordinaires de $1 chacune en 40,000 actions privilégiée* de $1 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 0 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517 3975-49 \u2014 1159/51 Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 5th day of February, 1963, have l»een issued by the Lieutenant-Governoivof the Province of Quebec, to \"Canadian Insurance Claims Service Corp.\", incorporated by letters patent dated July 22, 1954, changing its name into that of \"Canadian Insurance Claims Service Corporation \u2014 Service Canadien devaluation «le Sinistres Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 5th «lay of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 11610-54 - 1159/17 Chalet Barb-Q Incorporée Chalet Barb-Q Incorporated Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 6th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Chalet Barb-Q Incorporée \u2014 Chalet Burb-Q Incorporated\", 1.subdividing its 500 common shares of $100 each into 50,0(10 common shares of $1 each; 2.subdividing its 600 preferred shares of $100 each into 60,000 preferred shares of $1 each; 3.converting 40,000 common shares of $1 each into 40,000 prcferre«l shares of $1 each Given at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of Febniary, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25l7-o 3975-49\u2014 1159/51 1702 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, Tome 96, No 14 Châteauguay Sand Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 25 janvier 1903, à la compagnie « Cbâteuuguuy Sand Incorporated », 1° étendant ses pouvoirs; 2° augmentant son capital de $25,000 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 250 actions ordinaires $100 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25 janvier 1903.Ia; Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.251 7-o 12954-58 \u2014 1159/52 Clix Fastener Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 16 janvier 1963, à la compagnie «Clix Fastener Corporation», 1° subdivisant 100 actions ordinaires de $100 chacune en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune; 2° modifiant les dispositions de ses lettres patentes concernant les actions privilégiées et les actions privilégiées catégorie « A » ; 3° augmentant son capital de $100,000 à $450,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 35,000 actions privilégiées catégorie « B » de $10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 16 janvier 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 1523-37 \u2014 1159/138 Châteauguay Sand Incorporated Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Châteauguay Sand Incorporated\", 1.extending its powers; 2.increasing its capital stock from $25,000 to $100,000, the additional capital stock being divided into 250 common shares of $100 each and into 500 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 12954-58\u2014 1159/52 Clix Fastener Corporation Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Clix Fastener Corporation\", 1.subdividing 100 common shares of $100 each into 10,000 common shares of $1 each; 2.modifying the provisions of its letters patent concerning the preferred shares and class \"A\" preferred shares; 3.increasing its capital from $100,000 to $450,000, the additonal capital stock being divided into 35,000 class \"B\" preferred shares of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 16th day of January, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 1523-37 \u2014 1159/138 Club de Golf Mont Gabriel, Inc.Club de Golf Mont Gabriel, Inc.Mont Gabriel Golf Club, Inc.Mont Gabriel Golf Club, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 19 février 1963, à la compagnie « Le Club de Golf de Piedmont, Limitée\u2014 Piedmont Golf & Country Club, Limited », constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 octobre 1961, changeant son nom en celui de « Club de Golf Mont Gabriel, Inc.\u2014 Mont Gabriel Golf Club, Inc.».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19 février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517-q 14867-61 \u2014 1159/53 Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Le Club de Golf de Piedmont, Limitée \u2014 Piedmont Golf & Country Club, Limited\", incorporated by letters patent dated Otober 24, 1961, changing its name into that of \"Club de Golf Mont Gabriel, Inc.\u2014 Mont Gabriel Golf Club, Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of February, 1963.Raymon otDou vi lle, Assistant Secretary of the Province.2517 14867-61 \u2014 1159/53 Commercial Administration Ine.Commercial Administration Inc.Administration Commerciale Inc.Administration Commerciale Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that, under Part I of partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, supplementary Jet-été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la ters patent, bearing date the 12th day of Fe-province «le Québec, des lettres patentes supplé- bruary, 1963, have been issued by the Licuterne ida ires, en «late «lu 12 février 1963, à la com- nant-Governor of the Province of Quebec, to pagnie « Commercial Administration Inc.\u2014 \"Commercial Administration Inc.\u2014 Administra-Administration Commerciale Inc.», augmentant tion Commerciale Inc.\", increasing its capital son capital de $40,000 à $80,000, le capital-actions stock from $40,000 to $80,C00, the additional additionnel étant divise en 40,000 actions ordi- share capital being divided into 40,000 common naires de $1 chacune.shares of $1 each.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, Given at the office of the Provincial Secretary, ce 12 février 1903.this 12th day of February, 1903.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville, Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.2517-o 12502-00 \u2014 1160/7 2 517 12502-60 \u2014'A160/7 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, So.//, 1703 EdlalT Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 4 février 1963, à la compagnie « ki 11 air Limited », augmentant son capital de $29,000 à $80,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 0,000 actions privilégiées de $10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond dor ville.2517 1698-34 \u2014 1158/112 Foam Specialty Supply Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accor«lé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 14 féverier 1963, à la compagnie « Foam Special tv Supply Inc.», augmentant son capital de $20,000, à $40,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 14 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 11899-62 \u2014 1159/54 EdlafT Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quelwc Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 4th day of February, 1903, have been issue*I by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Edlaff Limited\", increasing its capital from $20,000 to $80,000, the additional capital stock being divided into 6,000 preferred shares of $10 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 1698-34 -1158/112 Foam Specialty Supply Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 14th «lay of Febniary, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Foam Specialty Supply Inc.\", increasing its capital stock of $20,000, to $40,000, the additional capital stock being divided into 2,000 common shares of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 11899-62 \u2014 1159/54 Fonderie St-Hyacinthe Foundry Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 15 février 1963, à la compagnie « Fonderie St-Hyacinthe Foundry Ltd.», 1° étendant ses pouvoirs; 2° convertissant 250 actions ordinaires de $100 chacune en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 42467-53 \u2014 1160/9 Fonderie St-Hyacinthe Foundry Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Fonderie St-Hyacinthe Foundry Ltd.\", 1.extending its powers; 2.converting 250 common shares of $100 each into 250 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 42467-53 \u2014 1160/9 Les Formes & Supports Économiques Inc.Economic Forms & Supports Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 février 1963, à la compagnie « Les Formes & Supports Économiques Inc.\u2014 Economie Forms & Supports Inc.», augmentant son capital de $10,000 à $35,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,500 filetions ordinaires de $10 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 11733-62 \u2014 1160/10 Les Formes & Supports Économiques Inc.Economie Forms & Supports Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Les Formes & Supports Économiques Inc.\u2014 Economic Forms & Supports Inc.\", increasing its capital stock from $10,000 to $35,000, the additional share capital being divided into 1,500 common shares of $10 each and 100 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 11733-62\u20141160/10 Gala Manufacturing Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Gala Manufacturing Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of Februa- 1704 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEllEC, 6 avril 1063, Tome 95, So IL province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu 12 février 1963, a la compagnie « Rona Lee Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 23e jour de janvier 1958, changeant son nom en celui «le « Gala Manufacturing Inc.».Donné au bureau «lu secrétaire «le lu province, ce 12 février 1963.Le Sous-secretaire de la province, Raymond Douvillk.2517 10059-58\u2014 1159-55 ry, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Rona Lee Inc.\", incorporate*! by letters patent dated the 23rd day of January, 1958, changing its name to that of \"Gala Manufacturing Inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th «lay of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517-o 10059-58 \u2014 1159/55 Germer Holdings Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 25 octobre 1962, à la compagnie « Pot aux Fèves Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date «lu 18e jour «le février 1958, changeant son nom en celui de « Germer Holdings Corp.».Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 8e mars 1963.lœ Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2517 10347-58 \u2014 1159/50 Girard Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 1er février 1963, à la compagnie « Girard Inc.», 1 ° subdivisant 500 actions ordinaires de §100 chacune en 5,000 actions ordinaires «le 810 chacune, 250 actions privilégiées classe « A » «le $100 chacune en 2,500 actions privilégiées classe nné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 1er février 1903.Le Sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvillk.251 7-o 5214-50\u2014 1159.122 Germer Holdings Corp.Notice is hereby given that.Under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, hearing «late the 25th day of October, 1902.have Wen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"P«>t aux Fèves Inc.\", incorporated by letters patent dated the 18th day «>f February.1958, changing its name to that of \"Germer Holdings Corp.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of March, 1903.Raymond Douville, Assistant Secretary of th?Province.2517-o 10347-58 \u2014 1159/56 Girard Inc.Notice is hereby given that, und t Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 1st «lay of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Girard Inc.\", 1.subdividing 500 common shares of $100 each into 5,000 common shares of $10 each, 250 preferred shares class \"A\" shares of $100 each into 2,500 preferred class \"A\" shares of $10 each and 250 preferred class \"B\" shares of $100 each into 2,500 preferred class \"B\" shares of $10 each; 2.am ¦ m ling the privileges ami restrictions attached to its preferred class \"A\" shares and class \"B\" shares; 3.increasing its capital stock from $100,000 to $250,000, the additional capital stock being divided into 10,000 common shares of $10 each, 2,500 preferred shares class \"A\" of $10 each and into 2,500 preferred class \"B\" shares of $10 each.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 5*214-50\u2014 1159/122 Hébert Adjustment Bureau Ltd.Bureau d'Ajustement Hébert Ltée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les h ttres patentes supplémentaires, en date «lu 8 février 19(>3, à la compagnie «Ilél'cit Adjustment Bureau Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes en' date du 24 août 1953, changeant son nom en celui «le « Hébert Adjustment Bureau Ltd.\u2014 Bureau d'Ajustement Hébert Liée ».Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 8 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Douville.2517-o 19682-53\u2014 1159/93 Hébert Adjustment Bureau Ltd.Bureau d'Ajustement Hébert Ltée Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 8th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Hébert Adjustment Bureau Ltd.\", incorporated by letters patent on August 24, 1953, changing its name -to \"Hi:bcrt Adjustment Bureau Ltd.\u2014 Bureau «l'Ajustement Hébert Ltée\".Given at the office of the Provincial Secrctarv, this 8th «lay of February, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2517 19682-53\u2014 1159/93 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95.So.14 1705 Immeubles Nelson Inc.Avis est donné qu'eu vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 30 janvier 1903, à la compagnie « Immeubles Nelson Inc.», 10 réduisant sou capital de $15,000 à $2,500, le capital-actions annulé étant divisé en 350 actions ordinaires de $10 chacune et en 90 actions privilégiées de $100 chacune: 2° augmentant son capital de $2,500 à $100,000, le capital-actions additionnel étant divisé en K50 actions ordinaires de $10 chacune et en S90 actions privilégies «le $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30 janvier 1903.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.3517m 13922-00 - - 1100/30 The Italian Room Shoe Salon Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies dt> Québec, il a été accortlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 3 janvier 1903, à la compagnie « The Italian Room Shoe Salon Inc.», augmentant son capital-actions «le $0,000 à $50,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1,400 actions ordinaires de $10 chacune et 300 actions privilégies de $100 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 3 janvier 1903.Le Sous-secrétaire de lu province, Raymond Douvillk.2517 11144-02 1159/57 Juvénat de-la-Salle Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 21 février 1903, à la corporation s Juvénat «lu Mont-de-la-Salle », constituée en vertu des dispositions de la troisième partie de ladite loi des compagnies de Québec, par lettres patentes en date du 28 avril 1901, changeant son nom en celui de « Juvénat de-la-Salle ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21 février 19G3.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 11378-61 \u20141159/96 Immeubles Nelson Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, hearing «late the 30th «lay of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Immeubles Nelson Inc.\", 1.reducing its capital stock from $15,000 to $2,500.the cancelled share capital being divided into 350 common shares of $10 each and 90 preferred shares of $100 each; 2.increasing its capital stock from $2,500 to $100,000, the additional share capital being divided into H50 common shurcs of $10 each and 890 preferred shares of $100 each.(iiven at the office «jf the Provincial Secretary, this 30th «lay of January, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 1*3922-00 -1100/30 The Italian Room Shoe Salon Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd «lay of January, 1903, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"The Italian Room Shoe Salon Inc.\", increasing its capital from $0.000 to $50,000, the additional capital stock being divided into 1,400 common shares of $10 each ami 300 preferred shares of $100 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of January, 1903.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o I'll 44-62 \u2014 1159/57 Juvénat de-la-Salle Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Juvénat du Mont-de-la-Salle\", incorporated under the provisions of Part III of the Quebec Companies Act, by letters patent dated April 28, 1961, changing its name to \"Juvénat de-la-Salle\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517 11378-61 \u2014 1159/96 Mija Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 12 février 1963, à la compagnie « Mija Corporation », modifiant certaines dispositions de ses lettres patentes.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 12 février 1963.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.2517 15773-60 \u2014 1159/47 Mill-CIoak Mfg.Inc.F Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Mija Corporation Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of February, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, to \"Mija Corporation\", amending certain provisions of its letters patent.Given at the office of the Provincial Secretary, this 12th day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 15773-60 \u2014 1159/47 Mill-Cloak Mfg.Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary let- 1706 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 0 avril IMS, Tome 96, So IL été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 8 février 1963, à la compagnie « Mill-Cloak Mfg.Inc.», étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 8 février 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dor ville.2517 14017-62 - 1159/48 ters patent, bearing date the 8tb day of February, 1963, have been iMUed hy the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Mill-Cloak Mfg.Inc.\", extending its powers.liiven at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of February, 1963.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.2517-o 14017-62\u2014 1159/48 lies Pieds Légers (1963) Inc.Avis est donné qu'en vertu «les dispositions «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 24 janvier 1963, à la cor juration « Club Social Drummoml Inc.», constituée en vertu «les dispositions «le la troisième partie «le ladite Loi «les compagnies «le Québec, par lettres patentes en date du 1er décembre 1944, changeant son nom en celui de « Les Pie«Is Légers (1963) Inc.».Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 24 janvier 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.2517-o 4941-44 \u2014 1159/60 Placements Marthe Gagnon Ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 30 janvier 1963, a la compagnie « Placements Marthe Gagnon Ltée », augmentant son capital de $300,000 à $000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 3,000 actions privilégiées de $100 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30 janvier 1963.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2517-o 10163-62\u2014 1160/19 Les Pieds Légers (1963) Inc.Notice is hereby given that, under the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of January, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, to \"Club Social Drummond Inc.\", incorporate*! under Part III of the said Quebec Companies Act, by letters patent osc le bardeau, le papier-bardeau, le bardeau d'amiante, le papier goudronné, fabrique et démonte les échafaudages, fait l'assemblage de toute pièce de bois ou métal sur un chantier de construction y compris les opérations suivantes: formes à hé ton (boutique ou chantier), y compris le brochage et le pattage des formes, posage de paravents (bois ou métal), chassis, fenêtres, « \\\\ heather-strips », bardeau de bois ou de composition, divisions en acier et d'ameublements, tels que comptoirs et tablettes, y compris le ]M>sage «le plancher «le bois franc, qui utilise une scie mécanique ou toute machine nécessaire à lu préparation du bois sur un chantier de construction et «pii fait tout autre travail connexe.e) Le mot « contremattre » désigne tout salarié qui a l'autorité de donner des ordres à d'utitres salariés sur un chantier de construction./) Le mot «( entrepreneur » dé-signe toute jiersonne, physique ou morale, compagnie, association ou corporation qui travaille seule ou qui emploie «les salariés, qui surveille ou entreprend pour le compte d'autrui, à l'heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, écrite ou autrement, un ou plusieurs travaux visés par le décret.Le mot « entrepreneur » «lésigne également toute personne, compagnie, association ou corporation ayant habituellement des salariés permanents exécutant «les travaux mentionnés à l'article III.g) Le terme « compagnon électricien » désigne tout salarié qui détient une licence « C » en exécution de la Loi des Électriciens et des Installations Électriques (S.R.Q.1941, chapitre 172 et amendements).h) Le mot « gardien » «lésigne tout salarié préposé, «le jour ou de nuit, à la surveillance des immeubles en construction, «les outils y employés et des matériaux utilisés ou à l'être, du chauffage, des installations de toile ou autres, à la prévention des incendies, au maintien de l'ordre sur un chantier de construction, «lans les camps, édifices ou bâtiments sur lesdits lieux.Il «levra poinçonner sur demande de l'employeur.t) Le terme « installations électriques » désigne toutes les installations pour fins d'éclairage électrique, de chauffage électrique ou «le force motrice électrique, les installations de paratonnerres, y compris dans tous les cas les fils, conduits, accessoires, dispositifs, câbles et appareils électriques, formant partie de l'installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccor«le-ment de l'installation au réseau l'alimentant, lequel point de racconlement est au mur de l'édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du courant l'alimentant.j) Ix* mot « manoeuvre » désigne tout salarié préposé à la préparation manuelle du mortier, célanitc ou au transport à la brouette de toute substance similaire servant à la construction, les porteurs d'oiseaux, les hommes préposés spécialement au service des briqueteurs, des maçons, les préposés aux malaxeurs, des plâtriers ainsi que les préposés à la manutention du ciment en vrac.k) Le terme « mécanicien de machines fixes » désigne tout salarié qui opère sur un chantier de construction une chaudière ayant plus de quinze (15) livres «le pression par pouce carré./) Le terme « mécanicien en tuyauterie » a le même sens que lui donne la Loi concernant les mécaniciens en tuyauterie (S.R.Q., 1941, chapitre 173 et amendements).m) Le terme « mécanicien de générateur de vapeur » désigne tout salarié qui fait l'installation et l'alignement d'appareils â mouvements alter- wooden articles and the laying of tarred paper and of felt, asliestos or other shingles, the erection and dismantling of scaffoldings, the assembling «»f any pieces of w«xxl or metal on a construction site, including the following operations: concrete forms made on the job or in the shop, including forms ticing and footing, setting of screens (w(m)d or metal), windows, windowf rames, weatherstrips, wood or composition shingles, steel and equipment partitions, such as counters and shelving, including the laying of hurdwood floors, the operation of a power saw or of any woodworking machine on a construction site ami any other occupation connected therewith.e) The word \"foreman\" means an employee authorized to give order! to other employees on a construction job./) The word \"contractor\" means any person, company, association or corporation working alone or hiring one or many workmen, who supervises or contracts for, on an hourly, daily or job basis, by verbal or wirtten agreement or otherwise, one or more of the operations gov- erned by the decree.The word \"contractor\" also means any person, company, association or corporation habitually employing permanent wage-earners to perform operations mentioned in article III.g) The term \"electrician journeyman\" means an employee holding license \"C\" un«ler the Electricians ami Ehctrical Installations Act (R.S.Q., 1941, chapter 172.as amended).h) The word \"watchman\" means an employee whose work, by day or night, is concerned with the watching of buildings under construction, tools and materials used or to lie used, beating apparatus and canvas installations, or with fire prevention or with maintaining order on a job, in camps or buildings on the construction site.He shall punch a clock if the employer so requires.i) The words \"electrical installations\" mean all installation* for purposes of electrical lighting and heating, power installations, lightning-rod installations, including in all cases wires, cables, conduits, accessories, devices and electrical apparatus included in the installation itself, connected with it or used in the connection of the installation with the supply service; the said connection shall be fixed to the wall of the building or construction nearest to the supply service.' j) The word \"labourer\" means a worker doing the manual preparation or the conveying with a wheel-barrow of mortar, celanite or any other similar material used in the construction industry, and includes hod carriers and men whose work is to assist bricklayers, masons, mixer operators and plasterers, including the employee handling bulk cement.k) The words \"stationary engine m an\" mean any employee who operates, on a construction site, a boiler where the présure exceeds fifteen (15) pounds per square inch./) The words \"pipe mechanic\" have the same meaning as is given to them in the Pipe Mechanics Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 173 and amendments).m) The words \"steam generator mechanic\" mean an employee who does the installation and lining up of alternating or rotating ma- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, IMS.Vol.9.5.So./', 1711 natifs OU rotatifs, tels qu'éventails, moteurs, pompes, pulvérisateurs, foyers mécaniques et toute machine à combustion ou autre utilisée pour la production de la vapeur.n) l> terme « mécanicien d'installations à vapeur ou à eau chaude » désigne tout salarié préposé à l'installât ion des foyers mécaniques istokers) dans les fournaises dont la surface horizontale de chauffe est de pas plus de vingt ('20) pieds carrés.o) Le terme « ouvrier en construction (Millwright) » désigne tout salarié prépose'- à l'installation et/ou à l'entretien «le machinerie fixée en permanence ou à titre «l'expérience sur un chantier de construction ou dans une usine.p) Le terme « salaire minimum » signifie le taux spécifié dans le décret.q) Ià: terme « salaire régulier » signifie le taux de salaire convenu entre l'employé et son employeur ou le représentant de ce dernier, si tel taux de salaire est supérieur au minimum fixé «lans le décret.r) Ia: terme etency of a pipe mechanic, performed inside or outside any building, including installation, repair and renovation works.c) It shall also apply to all employers and employees doing all kinds of work with cork or asbestos for refrigerating, heating or insulating purposes connected with the pipe mechanic trade.Workers carrying out such operations shall be paid according to the rates of wages established for their category in the decree for both installation and service purposes.d) Washing and cleaning done prior to painting and decorating operations inside or outside churches, chapels or any other public building, shall be governed by the decree and all male employees doing such work are considered as labourers.e) The decree shall also apply to the installation of elevators and the construction of steam generators, boilers and tanks, and to the installation of metal structures or frame-work.IV.Exemptions: a) The pulp and paper, lumber and power industries are exempt from the provisions of the decree as regards the maintenance of their properties provided a private collective labour, agreement entered into with a bona fide union, l>e in force and establish working conditions more advantageous than the ones provided for in the decree.6) All operations governed by Ordinances number 30 (lumber industry) and 39 (Forest operations) of the Minimum Wage Commission, are not governed by the decree.c)The operations of mines is exempt from the provisions of the decree.Mining Companies whose employees are governed by a collective agreement which provides for conditions at least equivalent to those of the decree are not subject to the decree, except for works executed by contractors or sub-contractors. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, No.14 1713 d) Les compagnies de chemins de fer ne sont pas assujetties au décret lorsqu'il s'agit de travaux ordinairement exécutés par les préposés ù l'entretien du réseau, si ces derniers sont déjà régis par une convention collective particulière prévoyant des conditions équivalentes ou supérieures à celles fixées dans le décret.e) Les cités, villes et les corporations municipales ou scolaires ne sont pas assujetties aux dispositions du décret pour ce qui est des travaux de réparation et d'entretien des immeubles qu'elles possèdent, pour ce qui est également des travaux de construction, de réfection ou d'entretien d'aqueduc, d'égouts, de pavages, de trottoirs et autres travaux du même genre exécutés sous leur contrôle immédiat.Cependant, l'exemption ne s'applique pas aux entrepreneurs et aux sous-entrepreneurs qui exécutent les mêmes travaux en régie ou à forfait pour le compte desdites cités, villes ou corporations municipales ou scolaires./) Le décret ne s'applique pas aux salariés permanents tels que définis par la Loi de la convention collective qui sont préposés à l'entretien d'un établissement industriel ou commercial.g) Les travaux de voirie exécutés pour le compte de l'un ou l'autre des départements du Gouvernement provincial, y compris les pon-ceuax, déjà assujettis en fait à la Cédule des Justes Salaires en exécution de l'arrêté en conseil numéro 800 du 24 avril 1929 et ses amendements, ne sont pas régis par les dispositions du présent décret.Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux travaux de construction de ponts, viaducs, tunnels et édifices publics, exécutés pour le compte de l'un ou l'autre des départements ci-haut mentionnés.Chapitre 3 Durée du travail, temps supplémentaire, jours chômés, salaires, vacances payées V.Durée du travail: a) La durée maximum du travail au taux régulier est de dix (10) heures par jour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de cinq (5) heures le samedi avant-midi.Toutefois, dans la région de Mattagami il sera loisible de travailler durant cinq (5) heures le samedi après-midi au taux régulier.6) Tout travail exécuté en plus du nombre d'heures quotidiennes régulières, ainsi que le samedi après-midi dans la Zone I, est considéré comme du temps supplémentaire et doit être rémunéré au taux de salaire et demi par rapport au salaire régulier, excepté dans le cas des gardiens.Toutefois, pour les travaux exécutés à plus de vingt-cinq (25) milles des limites des cités et villes comprises dans la Zone I, lorsqu'il s'agit de travaux destinés à l'exploitation des pouvoirs d'eau, à l'aménagement d'établissements industriels ou à la défense nationale, les dispositions concernant le salaire et demi par rapport au salaire régulier ne s'appliqueront pas pour le samedi après-midi.Cependant, dans aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne doit excéder soixante (60) heures au taux régulier.c) Jours chômés: Dans les zones I et II, il n'y a pas de travail les dimanches et les jours de fêtes suivants: le premier jour de l'An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Travail, le jour de Noël et le 20 décembre.d) Railroad companies are not governed by the decree in the case of works ordinarily performed by maintenance men of the system who are already covered by a private collective agreement with the said railroad companies prividing for conditions either equivalent to or more advantageous than those established by the decree.e) The cities, towns and municipal or school corporations are not governed by the provisions of the decree inasmuch as repair or maintenance work on their own buildings are concerned; inasmuch also us construction, rebuilding or maintenance works on aqueducts, sewers, pavings, sidewalks and other works of the same kind performed under their immediate control are concerned.The exemption does not apply, however, to contractors or sub-contractors carrying out the same works on their behalf or by the job for the said cities, towns or municipal or school corporation./) The decree shall not apply to permanent employees, as defined in the Collective Labour Agreement Act, whose work is concerned with the maintenance of an industrial or commercial establishment.g) Road operations carried out on behalf of any Deaprtment of the Provincial Government, encluding culverts, already governed by the Fair Wage Schedule under Order in Council number 800 of April 24, 1929 and its amendments, are not governed by the provisions of the present decree.However, bridge, tunnel, viaduct ami public building construction operations carried out for any one of such departments shall be subject to the decree.Chapter 3 Duration of work, overtime, holidays, wages, vacation with pay V.Duration of work: a) The maximum duration of work at regular rates shall be ten (10) hours per day on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday and five (5) hours on Saturday morning.However, in the region of Matagami, work is permitted during five (5) hours on Saturday afternoon at straight time.6) Except for watchmen, all time worked in zone I in excess of the number of regidar daily hours as well as time worked on Saturday afternoon, shall be considered as overtime and paid at the rate of time and one half based on the regular rate.However, outside the cities and towns comprised in zone I ami a radius of twenty-five (25) miles from their limits, in the case of operations concerned with the exploitation of hydraulic resources, with the setting up of industrial establishments or with National Defence, the provisions concerning time and one half rates shall not apply to time worked on Saturday afternoon.However, the regular duration of work at regular rates shall never exceed sixty (60) hours.c) Holidays: In zones I and II, there shall be no work on Sunday and the following holidays: New Year's Day, January 2, Good Friday, St-Jean Baptiste Day, Labour Day, Christmas Day and December 26. 1714 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBECt 6 avril 1963, Tome 95, So 14 Tout truvuil régi par le décret et exécuté durant les jours mentionnés au paragraphe précédent doit être rémunéré à raison de salaire double par rapport an salaire régulier, excepté dans le cas des gardiens.d) La construction «le routes, les travaux «le nivellement, «le terrassement, le posage d'asphalte et l'excavation à caractère résidentiel, à cause de leur caractère saisonnier l>énéficicnt des conditions suivantes: La semaine régulière «le travail pour les salariés qui y stmt employés est «le soixante (60) heures, sans limitation quotidienne de la journée de travail.Tout travail exécuté en plus «le ce nombre tie soixante (60) heures pendant une même semaine tie calendrier doit être rémunéré à raison tie salaire et «lemi par rapport au salaire régulier, excepte1 dans le cas tics gardiens.e) Pour les travaux d'isolation (laine minérale sous pression ou en coussins), les |>olisseurs «le terrazzo.les tireurs de joints et les maçons appelés à travailler à plus de quarante (40) milles «le la localité où ils résident, pourront travailler plus «le «lix (10) heures «lans une même journée sans temps supplémentaire, pourvu que leur semaine de travail ne dépass«> pas soixante (60) heures.VI.Taux minima de salaires: a) Les taux minima «le salaires suivants doivent être payés: Métiers ou occupations \u2014 Trades Amiantcur \u2014 Asbestos layer.All operations governed by the decree and performed on the days mentioned in the foregoing paragraph shall he paid double time computed on the regular wage rate, except in the case of watchmen.d) The construction of roads, levelling opera-tiens, earthworks, asphalt laying and excavating work for residences, being seasonal in character, shall benefit by the following conditions: The standard work week of employees concern -e«l consists of sixty (00) hours, without daily limitation of the duration of work.Except for watchmen, all time worketl in cscess of sixty (60) hours in any one calendar week shall lie paid at the rate of time and one half based on regular rates of pay.e) In the case of insulating operations (steel wool in pads or most) terrazzo polishing, joint pointing, masonry work employees required to work more than forty (40) miles away from the place where they live, may work more than ten (10) hours in the same day without overtime providing their work week floes not exceed sixty (60) hours.VI.Minimum wage rates: a) The following shall be the minimum wage rates: Taux horaires Hourly rates Zones I $1.85 1.75 Briqueteur, maçon \u2014 Bricklayer, mason.2.00 Brûleur \u2014 Burner.1.80 Charpentier-menuisier \u2014 Carpenter-joiner.1.90 Chauffeur «le camion à béton (Ready-Mix) \u2014 Truck krivcr (Ready-Mix).1.60 Chauffeur «lc camion erator.1 65 Foreur (Shaft ou Rase) \u2014 Drill operator (Shaft or Rase).2.00 Forgeron \u2014 Blacksmith._.1.70 Forgeron (préposé aux machines tlrill-sharpcncr) \u2014 Blacksmith (drill-sharpener) operator).1.90 Gardien et chauffeur de bouilloires (chaudières) \u2014 Watchman and boiler fireman 1 55 Gréeu r \u2014 Rigger.1-70 Huileur (plan de malaxeur) (tie pelle) \u2014 Mixer plant oiler, Power shovel oiler.1.55 Isolation (laine minérale sous pression et en coussins) \u2014 Insulation (pads and loose) 1 60 Journalier \u2014 Common worker.1 \u2022 50 Limeur \u2014 Filer.1-85 Machiniste \u2014 Machinist.2.00 Manoeuvre \u2014 Labourer.#.§\u2022?Mécanicien (moteur Diesel et gazoline) \u2014 Mechanic (Diesel and gasoline motor).// $1.70 1.85 1.65 1.75 1.45 1.45 1.40 1.55 1.45 1.60 1.90 1.75 2.00 Mécanicien (gazolinc seulement) \u2014 Mechanic (gasoline only).¦ .1.90 Mécanicien (machine fixe ou portative) \u2014 Engineman (stationary or portable engine) 1.80 Mécanicien en tuyauterie, plombier, poseur d'appareils de chauffage, brûleur à l'huile \u2014 Pipe mechanic, plumlwr, steamfitter, oil burner mechanic.1.85 Compagnon junior \u2014 Junior journeyman.;.1-70 Mécanicien monteur de générateur électrique \u2014 Electric generator mechanic.2.00 Ouvrier en construction \u2014 Millwright.1.70 Opérateur de scie à disque d'émeri \u2014 Emery disc saw operator.1.55 Opérateur de machine à sabler les planchers \u2014 Floor polisher operator.1.75 Opérateur de concasseur \u2014 Crusher operator.1 60 3.50 1.75 1.70 1.75 1.60 1.60 1.50 1.85 1.55 1.75 1.40 1.55 1.40 1.45 1.35 1.70 1.85 1.40 1.85 1.75 1.65 1.70 1.55 1.85 1.55 1.40 1.60 1.45 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.96, No.H_1715 Taux horaires Hourly rates Zones Métiers ou occupations \u2014 Trades I II Peintre \u2014 Painter.$ 1.70 $ 1.55 Peintre (préposé aux machines à asperger) \u2014 Spray painter.1.75 1.60 Peintre (lettreur et doreur) \u2014 Painter (ïetterer and gilder).2.00 1.85 Peintre (travaillant à plus de 45 pieds de hauteur ù l'extérieur) - - Painter (work done outdoors at a height exceeding 45 feet).2.00 1.85 Plâtrier - Plasterer.2 00 1 85 Préposé au rouleau (asphalte) - Asphalt rooler operator.1.65 1 .50 Préposé au rutelage de l'asphalte \u2014 Asphalt raker.1 80 1 .65 Préposé.à la machine à étendre l'asphalte \u2014 Asphalt spreader operator.1 SO 1 .65 Polisseur de terrazzo (à sec) \u2014 Terrazzo polisher, dry process.1.90 1.75 Polisseur de terrazzo (humide) \u2014 Terrazzo, wet polisher.1.80 1.65 Poteur «l'eau (moins de 18 ans) \u2014 Water carrier (under 18 years).0.85 0.70 Porteur «l'eau (plus «le 18 ans) \u2014 Watt r carrier (above 18 years).1.50 1.35 Poseur «le fenêtres \u2014 Window setter.1-65 1.50 Poseur «le gicleurs \u2014 Sprinkler fitter.2.00 1.85 Poseur «le lattes (gypse OU métal) \u2014 Lather (gypsum «>r metal).1.70 1.55 Poseur «le linoleum \u2014 Linoleum layer.1 80 1.65 Poseur «le fer d'armature \u2014 Reinforcing steel erector.1-50 1.35 Poseur tie revêtement extérieur en feuilles (moins tic 60' de hauteur) \u2014 Outside sheating (less than 60' high).1 90 1.75 (Plus tie 60' et moins de 110' de hauteur) \u2014 (More than 60' ami less than 110' high).2.00 1.85 (Plus de 110'de hauteur\u2014 More than 110'high).2 15 2.00 Préposé à la manuhntion tlu fer d'armature \u2014 Reinforcing steel handler.1 50 1.35 Préposé au pliage du fer «l'armature \u2014 Reinforcing steel (l>enrk done by such homeworker, in accordance with the piece work or unit price as determined and fixed by the Joint Commission.In the event of a breach of any of the provisions of Section XII of this decree, the Joint Commission shall have the right to invalidate the registration of any such Homework Employer, who shall thereupon no longer have the right to directly or indirectly engage in homework.\" Jacques Prémont, 2550-o Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 493 Section \"B\" Quebec, March 26, 1963.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an extension of the duration of the decree relating to the construction industry and trades in the region of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the «lecree number 613 of April 6, 1962, and all its amendments, including all sections incorporated in the form of special and complementary provisions applying to certain trades, relating to the construction industry and trades in the region of Montreal, Ik?extended until June 30, 1903.The present section replaces section \"C\" of Order in Council number 384 of March 12, 1963.Jacques Fremont, 2550-o Associate Clerk of the Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1.963.Vol.95.No.14 1721 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 493 Section « C » Québec, le 20 mars 1963.Présent: Le lieutenunt-gouvcrncur en conseil.( 'onckhnant lu prolorgutirii du décret relatif à Findustric du fer et du bronze d'ornenu ntation dans la région de Montréal.Il kst on donné, sur la proposition de l'honorable Ministre «lu Travail: Que le décret numéro 790 du 8 mai 1902, relatif à l'industrie du fer et du bronze d'ornementation dans la région de Montréal, soit prolongé jusqu'au 30 juin 1963.Jacques Prémont, 2650*0 Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 493 Section « D » Québec, U 26 mais 1963.Présent: Le Ikutenant-gouvcrnevr en conseil.Concernant une nu dificul i< n BU «lécret relatif à l'industrie «le la const ruction «lans la région de Québec.Attendu que, confoiniémint aux di.sp lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la pose d'affiches, de panneaux-réclames, d'enseignes lumineuses et l'établissement de cimetières d'automobiles le long des autoroutes et des voies de raccordement.Attendu Qu'en vertu des articles 24 et 25A de la Loi des autoroutes (Statuts refondus 1941, chapitre 141 A) les affiches, panneaux-réclames, enseignes lumineuses et l'établissement de cimetières d'automobiles sont prohibés le long des autoroutes en déça d'une distance déterminée par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazette officielle de Québec; Attendu Qu'il est important de protéger les abords et les voies de raccordement «les autoroutes contre tout enlaidissement et particulièrement as regards the administration of the decree governing the ornamental iron and bronze industry in the region of Montreal.It is ordained, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the right to levy of the Building Materials Joint Committee, authorized by a by-law approved bv or«ler in council number 1110 of July 10, 1902, published in the Quebec Official Gazette of July 21, 1962, as regards the administration of the decree number 790 of May 8, 1902, governing the ornament iron and bronze industry in the region of Montreal, ge extended until June 30, 1903, with the same rate and conditions.Jacques Prémont, 2550-o Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 493 Section \"A*\" Quebec, March 26.1963.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the levy by-law of \"Le Comité paritaire du Commerce «le Détail de Chieoutimi\".It is ordained, upon the recommandation of the Honourable the Minister of Labour: That the levy by-law of \"Le Comité paritaire du Commerce de Détail «le Chieoutimi\", approved by Onler in Council number 2121 of December 19, 1902, section \"A\", published in the Quebec Official Gazette of December 29, 1902, be amended by replacing the words \"a sum equivalent to j i 01 1%\" app< aring in paragraphs \"a\" and \"c\" c f the section 1.levy, by the words \"a sum equivalent to x/i of 1%\" and by replacing paragraph \"b\" of the same section by the following: \"6) The artisans governed by the said decree number 193 and amendments shall pay to the Parity Committee a sum equivalent to J £ cl 1% of the lowest wages established in the «lecrec for journeymen, i.e.a monthly levy of $1.00.\" Jacques Prémont, 2550-o Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 42 Quebec, January 9, 1903.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the placing of posters, panel-board advertising, luminous signs and the establishment of automobile cemetaries along autoroutes and road junctions.Whereas under section 24 and 25A of the Autoroute Act (Revised Statutes 1941, chapter 141 A) posters, panel-board advertising, luminous signs and the establishment of automobile cemeteries are prohibited along the autoroutes within a distance determined by an order of the Lieutenant-Governor in Council published in the Quebec Official Gazette; Whereas it is important to protect the approaches and the road junctions of the autoroutes against any disfigurement and especially against QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, IMS, Vol.M, So.I 1723 contre la pose d'affiches, de panneaux-réclames, d'enseignes lumineuses et l'établissement de cimetières d'automobiles, en deçà d'une distance déterminée de ces autoroutes et voies de\" raccordement; Attendu qu'il y a lieu de déterminer la distance en deçà de laquelle la pose d'affiches, de panneaux-réclames d'enseignes lumineuses et l'établissement de cimetières d'automobiles sont prohibés le long des autoroutes et des voies de raccordement; Attendu que par un arrêté en conseil du 13 juillet 1961, portant le numéro 1586, la distance en deçà de laquelle la pose d'affiches et «le panneaux-réclames est prohibée, le long de l'Autoroute «les Laurcntidcs a été fixée à mille pieds de la ligne d'emprise de cette autoroute sur tout son parcours et «le chaque côté.Il est ou don né, en conséquence, sur la proposition du Ministre de la voirie: Que l'arrêté en conseil du 13 juillet 1961, por-tunt le numéro 1586 soit remplacé par le présent urrêté.Que le distance en deçà de laquelle la pose d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes lumineuses est prohibée le long «les autoroutes et «les voies de raccordement soit fixée ù mille pieds de la ligne d'emprise de ces autoroutes sur tout leur parcours et de chaque côté.Que la distance en deçà de laquelle les cimetières d'automobiles sont prohibés le long des autoroutes et des voies de raccordement soit fixée à mille pieds de la ligne d'emprise de ces autoroutes sur tout leur parcours et de chaque côté.Jacques Prémont, 2578-0 Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.Avis divers Mountainview Baptist Church Avis est donné que « Mountainview Baptist Church », une congrégation baptiste ayant son temple à 240, Montigny, St-Hilaire, P.Q., s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir sa constitution en corporation sous le nom de « Mountainview Baptist Church », conformément aux dispositions du chapitre 311, S.R.Q., 1941.Ltt Procureurs de la requérante, 2420-12-5 Hutciieson, Johnston & Todd.Paroisse des Trois-Rivières Avis est par les présentes donné que la corporation municipale de la « Paroisse des Trois-Rivières », adressera une requête à l'honorable lieutenant-gouverneur en conseil, demandant l'érection de son territoire en municipalité de ville.Le nom de la municipalité projeté de ville sera le suivant: « Ville de Trois-Rivières Ouest ».Le territoire actuel de la municipalité de la paroisse des Trois-Rivières, comté de St-Maurice, division d'enregistrement de Trois-Rivières, province de Québec, comprenant en référence au cadastre officiel de ladite paroisse, les lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, rues, ruelles emprises de chemin de fer, rivières, cours d'eau ou parties d'iceux renfermés dans les limites suivantes: Plus explicitement, référant au cadastre officiel de la « Paroisse des Trois-Rivières », division d'enregistrement de Trois-Rivières, cadastre the presence of posters, panel-board advertising luminous signs ami the establishment of cemeteries within a determined distance of these auto-routes and road junctions; Whereas it is deemed expedient to determine the distance within which the placing of posters, panel-board advertising, luminous signs and the establishment of automobile cemeteries is prohibited along these autoroutes and road junctions; Whereas by an order in council of July 13, 1901, bearing number 1586, the distance within which the placing of posters, panel-board advertising and luminous signs is prohibited along the Laurentian Autoroute has been fixed to one thousand feet of the right-of-way of this auto-route along the whole of its course and no each side.It is therefore ordained, upon the proposition of the Minister of Roads: That onler in council of July 13, 1961, bearing number 1586 be replace«l by the present order.That the distance within which the placing of posters, panel-boar«l advertising and luminous signs is prohibited along the autoroutes and road junctions be fixed to one thousand feet from the right-of-way of these autoroutes along the whole of their course and on each side.That the distance within which the automobile cemeteries are prohibited along the autoroute and road junctions be fixed to one thousand feet from the right-of-way of these autoroutes along the whole of their course and on each side.Jacques Prémont, 2578 Associate Clerk of the Executive Council.Miscellaneous notices Mountainview Baptist Church Notice is hereby given that \"Mountainview Baptist Church\", a Baptist Congregation having its place of worship at 240, Montigny, St.Hilaire, P.Q., shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for incorporation under the name of \"Mountainview Baptist Church\", in conformity with the provisions of chapter 311, R.S.Q., 1941.Hutcheson, Johnston & Todd, 2426-12-5-o Attorneys for the Petitioners.Parish of Trois-Rivières Notice is hereby given that the municipal corporation of the \"Parish of Trois-Rivières\", will submit a request to the Honourable the Lieutenant-Governor in Council, requesting the erection of its territory into a town municipality.The.name of the planned town will be as follows: \"Town of Trois-Rivières Ouest\".The present territory of the municipality of the \"Parish of Trois-Rivières\", county of St-Maurice, registry division of Trois-Rivières, Province of Quebec, comprising with reference to the official cadaster of said parish, the lots and their present and future subdivisions, as well as the roads, streets, lanes, railroad right of way, rivers, waterways or parts of the same enclosed within the following boundaries : More explicitly, refering to the official cadaster of the \"Parish of Trois-Rivières\", registry division of Trois-Rivières, official cadaster in which all 1724 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968.Tome 96.So 14 officiel dont tout le territoire faisant l'objet des présentes n'est qu'un démembrement, le susdit territoire de ladite municipalité comprend: le lot No un (1) du susdit cadastre officiel de la « Paroisse des Trois-Rivières »; le lut deux (2) dudit cadastre, sauf et à distraire la partie annexée au territoire de la cité de Trois-Rivières; les lots Nos trois (3) à cent soixante-six (166) du susdit cadastre officiel; le lot No trois cent soixan-te.quatorze (374) du susdit cadastre officiel.Tous les chemins, cours «l'eau, lacs, rivières, partie d'ieeux compris dans le territoire borné au sud-ouest par le territoire de la municipalité de la paroisse de la Visitation de la Pointe-«lu-Lac, comté de St-Maurice, au nord-ouest et au nord-est par le territoire «le la cité «le Trois-Rivières, au sud-est par le fleuve St-Laurent.À cette fin un certificat «lu secrétaire-trésorier démontre que la population se chiffre à 5,100 ftmes en date du 15 mars 1903.La municipalité «le la ville «le Trois-Rivières Ouest sera érigée en ville sous l'empire «le la Loi des Cités et Villes.Signé à: «Paroisse des Trois-Rivières», district des Trois-Rivières, Province de Québec, ce 19ième jour de mars 1903.Le Maire, Jules Montour.La: Secrétaire-trésorier, 2450-13-2-o Roland Desaulniers.L'Église Baptiste Évangélique de Verdun Avis est donné par les présentes que le Révérend William Henri Frey, pasteur, de même que messieurs Gérard Pomerleau et Daniel Lesar, diacres, s'addresseront au lieutenant gouverneur en conseil pour l'incorporation de « L'Église Baptiste Évangélique de Verdun », membre de l'association des Églises Baptistes Évangéliques du Canada, suivant les dispositions du chapitre 311 des Statuts Revisés de Québec.Montréal, Québec, le 12 mars, 19G3.Le Procureur des requérante, 2522-14-5-o E.J.Lattimer.Bills \u2014 Assemblée législative Chambre du Conseil lé«;islatif Québec, 27 mars 1903.Aujourd'hui, à cinq heures et quinze minutes de l'après-midi, l'honorable lieutenant-gouverneur s'est rendu à la chambre «lu Conseil législatif au Palais législatif.Les membres «lu Conseil législatif étant assemblés, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur d'y faire requérir la présence de l'Assemblée législative et, cette chambre s'y étant rendue, le greffier de la couronne en chancellerie a lu les titres des bills à être sanctionnés comme suit: 8 Loi des caisses d'épargne et de créxlit.9 Loi des associations coopératives.10 Loi modifiant la Loi des syndicats coopératifs de Québec.11 Loi modifiant la Loi des sociétés coopératives agricoles.24 Loi modifiant la Loi du ministère de l'industrie et du commerce.the territory being the object hereby given is only a dismemberment, the said territory included : the lot No.one (1) of the said official cadaster of tte \"Parish of Trois-Rivières\"; the lot No.two (2) of the said cadaster except the part annexed to the territory of the city of Trois-Rivières; the lots Nos three (3) to one hundred-sixty-six (100) of the said official cadaster; the lot No.three-hundreds-seventy-four (374) of the said official cadaster.All the roads, waterways, lakes, rivers, or parts of the same enclosed in the territory horned at the southwest by the territory of the municipality of the parish of the Visitation of the Pointe-ilu-Lac, county of St-Maurice, at the northwest and northeast by the territory of the city of Trois-Rivières, at the southeast by the St-Lawrence River.For this purpose a certificate from the treasurer-secretary showed a total of population being 5,100 souls, and that in date of March 16 1968.The municipality of the town of Trois-Rivières Ouest, will be erectetl into a town under the authority of the Cities and Towns Act.Signed at: \"Parish of Trois-Rivières\", district of Trois-Rivières, Province of Quebec, this 19th day of March 1963.Jules Montour, Mayor.Roland Desaulniers, 2450-13-2-o Secretary-Treasurer.L'Église Baptiste Évangélique de Verdun Notice is hereby given that the Reverend William Henri Frey, pastor, and Messrs.Gérard Pomerleau and Daniel Lesar, deacons, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for incorporation of \"L'Église Baptiste Évangélique de Verdun\", a member of the Fellowship of Baptist Churches of Canada, in accordance with the stipulations of Chapter 311 of the Revised Statutes of Quebec.Montreal, Quebec, March 12, 1963.E.J.Lattimer, 2522-14-5-o Solicitor for A pplicanis.Bills \u2014 Legislative Assembly Legislative Council Chamber Quebec, 27th of March 1963.This day, at fifteen minutes past five o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor procee«le«l to the Legislative Council Chamber, in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the attendance of the Legislative Assembly, and that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 8 Savings and Credit Unions Act.9 The Cooperative Associations Act.10 An Act to amend the Quebec Cooperative Syndicates Act.11 An Act to amend the Coopeative Agricultur- al Associations Act.24 An Act to amend the Industry and Commerce Department Act. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963.Vol.96, So.IL 172.5 25 Loi du ministère du tourisme, de la chasse et de la pêche.41 Loi concernant la liquidation des compagnies à fonds social.102 Loi autorisant le Marre au de la province de Québec à admettre Dénes Boronkay à l'étude du droit et à l'exercice de la profession d'avocat.103 Loi changeant le nom de Samuel Shatsky en celui de Samuel Shatsky Shadley.105 Loi changeant le nom d'Edward Hajdukie-wiez en celui d'Edward Hajdukiewicz Edwards.109 Loi changeant le nom de Gaétan Lévesque en celui de Jean M annula.110 Loi concernant l'adoption de Marie Ger- maine Lucie Sénécal.113 Loi changeant le nom de Stanley Krawczy- kiewiez en celui de Stanley Krawczykie-wicz Taylor.114 Loi changeant le nom de François Feldheim en celui de François Feldheim Feltin.118 Loi concernant l'adoption de Serge Turgeon et de Linda Turgeon.142 Loi refondant la charte de La Prévoyance Compagnie d'Assurances.156 Lei modifiant la charte de la cité de Verdun.172 Loi autorisant le Barreau de la province de Québec à admettre George Easdon à l'exercice de la profession d'avocat.La sanction royale est prononcée sur ces bills par le greffier du Conseil législatif, comme suit: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur sanctionne ces bills.» 30 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1903, et pour d'autres fins du service public.31 Loi octroyant à Sa Majesté des deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour l'année financière se terminant le 31 mars 1904 et polir d'autres fins du service public.À ces bills, la sanction royale a été donnée dans les termes suivants: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur remercie ses fidèles sujets, agrée leur benevolence et sanctionne ces bills.» 2573-q Compagnie autorisée à faire des affaires ABCC Finance (Ontario) Limited Avis est ici donné qu'en vertu de la Loi des Sociétés de prêts et de placements (S.R.Q.1941, c.288) « ABCC Finance (Ontario) Limited », une compagnie incorporée dans la province d'Ontario, a été autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec conformément aux dispositions de ladite loi.25 Tourism, Fish and dame Department Act.41 An Act respecting the winding-up of joint stock companies.102 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit Dénes Boronkay to the study and practice of the legal profession.103 An Act to change the name of Samuel Shatsky to that of Samuel Shatsky Shadley.105 An Act to change the name of Edward Hajdukiewicz to that of Edward Hajdukiewicz Edwards.109 An Act to change the name of Gaétan Lévesque to that of Jean Maranda.110 An Act respecting the adoption of Marie Germaine Lucie Sénécal.113 An Act to change the name of Stanley Krawczykiewicz to that of Stanley Kraw-czykicwicz Taylor.114 An Act to change the name of François Feldheim to that of François Feldheim Feltin.118 An Act respecting the adoption of Serge Turgeon and Linda Turgeon.142 An Act to consolidate the charter of The Provident Assurance Company.156 An Act to amend the charter of the city of Verdun.172 An Act to authorize the Bar of the Province of Quebec to admit George Easdon to the practice of the profession of advocate.To these bills the Royal assent was pronounced by the Clerk of the Legislative Council in the following words: \"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor assents to these bills.\" 30 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March 1903, and for other purposes connected with the public service.31 An Act granting to Her Majesty moneys required for the expenses of the Government for the financial year ending on the 31st of March 1904, and for other purposes connected with the public service.To these bills the Royal assent was signified in the following words: \"In Her Majesty's name the Honourable the Lieutenant-Governor thanks her loyal subjects, accepts their benevolence and assents to these bills.\" 2573-o Company Licensed to do Business ABCC Finance (Ontario) Limited Notice is hereby given that \"ABCC Finance (Ontario) Limited\", a company duly incorporated in the Province of Ontario, has been licensed to carry on business in the Province of Quebec pursuant to the provisions of the Loan & Investment Societies Act (R.S.Q.1941, c.288). 1726 BABETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 6 avril 1968, Tome 96, No 14 L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures BgBfejfai contre elle, est M.Albert Bronson Culver, avocat de 1321 rue Sherbrooke ouest, appartement H-100, Montréal, Que.Le siège social de ladite compagnie dans la province sera établi à 1500 rue Sherbrooke ouest, Montréal, Que.Daté à Montréal.27 février, 19(53.L'Agent enregistré, 2310-1 l-4-o A.B.Culver.Chartes \u2014 Abandon de Toldi Ltd.Avis est donné que lu compagnie « Toldi Ltd.», une corporation constituée en corporation, en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la ville de Montréal, province de Québec, s'adressera au secrétaire de la province de Québec, pour obtenir la i>ermis-sion d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 2e jour de janvier 1903.Toldi Ltd., Far le Président, 2519 K.A.Saxlehner.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.Albert Bronson Culver, Attorney, of 1321 Sherbrooke Street, West.Apt.B-100, Montreal, Que.The pi nteipaI office of the suid company in the Province is to In* established at 1500 Sherbrooke Street, West, Montreal, Que.Dated at Montreal.February 27.1903.A.B.Culver, 2310-11 -1 -o Registered Agent.Charters \u2014 Surrender of Toldi Ltd.Notice is hereby given that the company, \"Toldi Ltd.\", a corporatoin constituted under the Quebec Companies Act and having its bead office in the town of Montreal, district of Montreal, Province of Quebec, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies Act.Dated at Montreal, this 2nd day of January 1963.Toldi Ltd., Per: K.A.Saxlehner, 2519-0 President.Crémerie Sorel Inc.Prenez avis que la compagnie « Crémerie Sorel Inc.», demandera au Secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.2523-u Me Julks Trempe, notaire.Crémerie Sorel Inc.Notice is hereby given that the company \"Crémerie Sorel Inc.\", will ask to the Provincial Secretary the authorization to surrender its charter.2523-o Me Jules Trempe, notary.L'Association Néerlandaise de Montreal Je Maintiendrai Avis est donné que « L'Association Néerlandaise de Montréal Je Maintiendrai », une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec, ayant son siège social en la cité de Montréal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Daté à Montréal, ce 28e jour de mars 1963.Le Secrétaire, 2539 M.Polak.L'Association Néerlandaise de Montréal Je Maintiendrai Notice is hereby given that \"L'Association Néerlandaise de Montréal Je Maintiendrai\", a corporation constituted under the Quebec Companies' Act, having its head office in the city of Montreal, will apply to the Secretary of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Montreal, this 28th day of March, 1963.M.Polak, 2539-0 Secretary.La Compagnie Locale de Téléphone de St-Julien Prenez avis que « La Compagnie Locale de Téléphone de St-Julicn », demande au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le Procureur de la Compagnie, 2540-o Me W.James Johnson.La Compagnie Locale de Téléphone de St-Julien Take notice that \"La Compagnie Locale de Téléphone de St-Julien\", will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Me W.James Johnson, 2540 Attorney for the Company.St.Catherine-Crescent Development Corporation Ltd.Avis est par les présentes donné que « St.Catherine-Crescent Development Corporation Ltd.», a l'intention de demander au Secrétaire de la Province la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 28 mars, 1903.Le Secrétaire, 2551-o Philip F.Vinebero.St.Catherine-Crescent Development Corporation Ltd.Notice is hereby given under the Quebec Companies Act and amendments that \"St.Catherine-Crescent Development Corporation Ltd.\", intends to make application to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Montreal, March 28, 1903.Philip F.Vinebero, 2551-0 Secretary. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.96, No.U 1727 Liberty Realty Inc.« LilxTty Realty Inc.», donne, par les présentes, avis quelle s'adressera HI secrétaire de lu province de Quelle, pour obtenir lu permission (l'abandonner sa chart*'.Montréal, 27 mars 1088.Lt Procureur de lÀberiy Realty lue., 2564 David Litnek, ch.United Auto Parts (St-Joscph d'Alma) Ltd Avis est.par les présentes, donné (pie « United Auto Parts (St-Joseph d'Alma) Ltd », une compagnie dûment incorporée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social à St-Joseph d'Alma, «listrict «le Roltcrval, province «le Québec, demandera au Secrétaire «le la Province «le Québec, la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions «le ladite Loi.Signé à Montréal, ce lie jour «le mars 1963.Le Sécrétaire-trésorier, 2565-0 Y van Beauskjour.Ragot Construction Inc.Avis est par les présentes donné que « Bagot Construction Inc.», une compagnie constituée en corporation suivant les dispositions de la Première Partie de la Loi des Compagnies de Québec et ayant sa principale place d'affaires à Ste-Rosalie, comté «le Bagot, demandera la permission au Secrétaire de la Province de Québec d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des Compagnies de Québec.Daté à Ste-Rosalie, ce 1er jour d'avril 1963.Le Secrétaire, 2579-o André Dumont.Jacques Mathieu Inc.Prenez avis que la compagnie « Jacques Mathieu Inc.», demandera au secrétaire* de la province la permission d'abandonner sa charte.Let Procureurs de la compagnie, Mes Lacroix, Viau, Hébert 2580-o & Tiiivieroe.Liberty Realty Inc.\"Liberty Realty Inc.\", hereby gives notice that it will make application to the Provincial Secretary, Province of Quebec, f«>r acceptance of the Surremler of its Charter.Montreal, March 27, 1963.David Litner, q.c, 2564-o Attorney for Liberty Realty Inc.United Auto Parts (St-Joseph d'Alma) Ltd Notice is hereby given that \"United Auto Parts (St-Joseph d'Alma) Lt«l\", a company duly incorporated under the Quebec Companies Act and having its head office in St.Joseph d'Alma, district of Roberval, province of Quebec, will apply to the Secretary of the Province of Quebec for leave to surremler its charter under the provisions of the said Act.Signed at Montreal, this 11th «lav of March, 1963.Yvan Beauskjour, 2565-o Secretary-Treasurer.Bagot Construction Inc.Notice is hereby given that \"Bagot Construction Inc.\", a corporation incorporated under the Quebec Companies' Act and having its head office in Ste-Rosalic, in Bagot County, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Quebec Companies' Act.Dated at Ste-Rosalie, on the 1st day of April 1963.André Dumont, 2579-o Secretary.Jacques Mathieu Inc.Notice is hereby given that the company \"Jacques -Mathieu Inc.\", will apply to the Provincial Secretary, to ask permission to surrender its charter.Messrs.Lacroix, Viau, Hébert, & Tiiivierge, 2580-o Attorneys for the company.Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited En vertu des dispositions de la Loi des compagnies de Québec, telle qu'amendée, « Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited », donne avis par les présentes qu'elle fera application à l'honorable le Secrétaire de la province de Québec pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en ordonnance son annulation, et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Montréal, P.Q., le 28 mars, 1963.Le Secrétaire, 2581-o J.Hobus.Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited Under the provisions of the Quebec Companies' Act as amended, \"Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited\", hereby gives notice that it will make application to the Honourable the Provincial Secretary of Quebec for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a date upon and from which it shall be dissolved.Montreal, P.Q., March 28, 1963.J.Hobus, 2581 -o Secretary.Divers Compagnies Ace Metal Strip Ltd.Règlement No 21 « Qu'il soit et il est décrété comme un règlement de « Ace Metal Strip Ltd.», ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est augmenté de trois à quatre, de Miscellaneous Companies Ace Metal Strip Ltd.By-law No.SI \"Be it enacted and it is hereby enacted as a by-law of \"Ace Metal Strip Ltd.\", as follows : 1.The number of directors of the company be and the same is hereby increased from three to 1728 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1968, Tome 96, No 14 sorte qu'à l'avenir, le conseil d'administration de la compagnie sera dorénavant composé de quatre directeurs.2° Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du conseil d'administration.3° Tous les règlements, résolutions et procédures antérieurs de la compagnie, incompatibles à icclui, sont amendés, modifiés et revisés, de manière à donner effet à ce règlement.» Le précédent est une copie conforme du règlement adopté par le conseil d'administration de « Acc Metal Strip Ltd.», le dix-huitième jour de février 1903, et approuvé suhséqucmment par le vote unanime des actionnaires présents à une assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le dix-huitième jour de février 1903.Le Secrétaire, Normand Frenettb.2524 11149-50 four so that the board of directors of the company shall hereafter be composed of four directors.2.Three directors shall constitute a quorum at any meeting of the board of directors.3.All prior by-laws resolutions and proceedings of the company inconsistent herewith are hereby amended, modified and revised in order to give effect to this by-law.\" The foregoing is a true copy of the by-law adopted by the board of directors of \"Ace Metal Strip Ltd.\", on the eighteenth day of February, 1963, and subsequently approved by the unanimous vote of the shareholders present at a special general meeting of shareholders held on the eighteenth day of February, 1963.Normand Frenbtte, Secretary.2524-0 11149-56 Association of English-Speaking Interns of Montreal Extrait de l'article 14 des règlements généraux de la corporation ci-haut mentionnée, tel qu'adopté par les directeurs et approuvé par les membres de ladite corporation le 4 mai 1962, concernant une augmentation du nombre des directeurs de trois ù dix-huit: « Consseil d'administration \u2014 Article 14 \u2014 Composition\u2014«Les affaires de l'association seront dirigées par un conseil d'administration comprenant deux membres généraux de chaque hôpital représenté dans l'association.» Copie conforme certifiée.Le Secrétaire, D.Airman.2525 10895-62 Association of English-Speaking Interns of Montreal Extract of Article 14 of the general by-laws of the above-named corporation, as adopted by the directors and approved by the members of the said corporation on May 4, 1962, concerning an increase in the number of directors from three to eighteen : \"Board of directors \u2014 Article 14 \u2014 Composition \u2014 \"The affairs of the association shall be managed by a board of directors consisting of two general members from each hospital represented in the association.\" Certified true copy.D.Airman, Secretary.2525-o 10895-62 Association of English-Speaking Interns of Montreal Avis est donné que l'honorable secrétaire de la province a, le 13 mars 1963, approuvé les règlements généraux de « Association of English-Speaking Interns of Montreal », et ce, conformément aux dispositions de l'article 225, de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28 mars 1963.Le Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douville.2525-o 10895-62 Association of English-Speaking Interns of Montreal Notice is given that the Honourable the Provincial Secretary has, on March 13, 1963, approved the general by-laws of \"Association of English-Speaking Interns of Montreal*, and such, pursuant to the provisions of section 225, of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, on March 28, 1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2525 10895-62 Bétonnière Mont-Bruno Limitée Mount Bruno Ready Mix Limited Règlement numéro 4 concernant la modification du nombre des directeurs.« Le nombre des directeurs de la compagnie « Bétonnière Mont-Bruno Limitée \u2014 Mount Bruno Ready Mix Limited », est changé de 3 qu'il était auparavant à celui de 4 en vertu du règlement numéro 4 ».Copie certifiée du règlement numéro 4 dûment adopté à une assemblée des directeurs tenue le 13ème jour de février 1963 et approuvé à une assemblée générale spéciale de la compagnie tenue le 13e jour de février 1963 par les actionnaires détenant entre eux 100% des actions représentées à cette assemblée.Le Secrétaire, Pierre Dulude.2526-o 12704-01 Bétonnière Mont-Bruno Limitée Mount Bruno Ready Mix Limited By-law number 4 concerning the amendment in the number of the directors.\"The number of the directors of the company \"Bétonnière Mont-Bruno Limitée \u2014 Mount Bruno Ready Mix Limited\", is changed from 3 that it was formerly to that of 4 under bylaw number 4\".Certified copy of by-law number 4 duly adopted at a meeting of the directors held on the 13th day of February, 1963, and approved at a special general meeting of the company held on the 13th day of February, 1963, by the shareholders holding among themselves 100% of the shares represented at this meeting.Pierre Dulude, Secretary.2520 12704-61 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1063, Vol.OS, \\o.1.', 1729 Chambre d'Immeubles de Québec Quebec Real Estate Board Extrait de l'article XI des règlements généraux de la corporation ci-haut mentionnée, tels qu'adoptés par les directeurs et approuvés par les membres le 27 décembre 1962, concernant l'augmentation du nombre des directeurs de cinq à sept: Art.XI directeurs \u2014 a) Membres.Les affaires de la chambre sont administrées par un bureau de sept (7) directeurs.Certifiée vraie copie.Le Secrétaire, P.-E.Doyon.2527-o 5778-47 Chambre d'Immeubles de Québec Quebec Real Estate Board Excertp of article XI of the general by-laws of the above mentioned corporation as adopted by the directors and approved by the members on December 27, 1962, concerning the increase in the number of the directors from five to seven: Art.XI directors \u2014 a) Members.The affairs of the chamber are administrated by a board of seven (7) directors.Certified true copy.P.-E.Doyon, Secretary.2527 5778-47 Chambre d'Immeubles de Québec Quebec Real Estate Board Avis est donné que l'honorable secrétaire de la province a, le 25 mars 1963, approuvé les règlements généraux de la « Chambre d'Immeubles de Québec \u2014 Queliec Real Estate Board », et ce, conformément aux dispositions de l'article 225, de la Loi des compagnies de Quél>ec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27 mars 1963.lé Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2527-o 5778-47 Chambre d'Immeubles de Québec Quebec Real Estate Board Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has on March 25, 1963, approved the general by-laws of \"Chambre d'Immeubles «le Québec \u2014 Québec R«*al Estate Board\", ami such, pursuant t«> the provisions of section 225, of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, on March 27, 1963.Raymon d Douville.Assistant Secretary of the Province.2527 5778-47 Mf March 1963.Y van Beauskjour, 2565-o Secretary-Treasurer.The Motor Truck Club (Quebec) Inc.Le Club de la Traction sur Routes (Québec) Inc.Avis est donné que l'honorable secrétaire ec) Inc.\u2014 Le Club de la Traction sur Routes (Québec) Inc.», et ce, conformément aux dispositions de l'article 225, de la Loi des compagnies de Québec.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 1er avril 1903.lé Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2574-o 377-03 The Motor Truck Club (Quebec) Inc.Le Club de la Traction sur Routes (Québec) Inc.Notice is hereby given that the Honourable the Provincial Secretary has, on March 28, 1963, approved by-laws numbers 1, 2 and 3 of \"The Motor Truck Club (Quebec) Inc.\u2014 Le Club de la Traction sur Routes (Québec) Inc.\", such, pursuant to the provisions of section 225, of the Quebec Companies Act.Given at the office of the Provincial Secretary, on April 1, 1963.R a ymon 0 Dot.' ville, Assistant Secretary of the Province.2574 377-63 St.Lawrence Sea Products Co.Règlement spécial « D » « Que le nombre des directeurs soit augmenté de 3 à 5 dont 3 constitueront un quorum et que les règlements No 9 et No 15 sont amendés en conséquence.» Je, soussigné, secrétaire de la compagnie, certifie que ceci est une copie exacte d'un règlement spécial adopté à une réunion de bureau de direction de la compagnie le 28 février 1903, et approuvé le même jour à l'unanimité par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.lé Secrétaire, Bernard Blais.2575-0 10584-57 St.Lawrence Sea Products Co.Special by-law \"D\" \"That the number of directors be increased from 3 to 5 of whom 3 shall constitute a quorum and that By-laws No.9 and No.15 be amended accordingly.\" I, the undersigned, secretary of the company, certify that this is a true copy of a special by-law enacted by the board of «lirectors at their meeting of February 28, 1903, and unanimously approved on the same date at a meeting of the shareholders duly called for this purpose.Bernard Blais, Secretary.2575-o 10584-57 La Société Jacques Labrecquc Limitée Règlement So 4 « Qu'il soit décrété et il est décrété comme un règlement de « La Société Jacques Labrecque Limitée », (ici nommée la « Compagnie ») ce qui suit: 1° Que le nombre des directeurs de la compagnie soit et il est augmenté «le trois à quatre, de sorte qu'à l'avenir, le conseil d'administration de la compagnie sera composé de quatre directeurs.2° Trois directeurs formeront quorum à toute assemblée du conseil d'administration.l.a Société Jacques Labrecque Limitée By-law So.4 \"Be it enacte»! ami it is hereby enacted as a by-law of \"La Société Jacques Labrecque Limitée\", (herein called the \"Company\") as follows: 1.The number of «lirectors of the company be an«l the same is hereby increased from three to four, so that the board of directors of the company shall hereafter l>e comi>oseour l'adoption «l'une loi amendant sa charte et lui accordant certains pouvoirs concernant les matières suivantes: pour former en corporation de cité les habitants ou contribuables «lu territoire de la ville de Pierrefonds et leurs successeurs; faire déclarer la ville propriétaire à toutes fins que «le «Iroit des lots ci-après possibles et utilisés oar elle comme rues publiques, lots numéros 23-1 (rue Hortie) 150-9, 151-51, 151-52, 151-53, 152-52 (rue Rive Boisée) 151-55, 152-55 (rue Du Docteur) 151-79 (rue David) 151-54, 151-90 (rue «les Maçons) partie lot 177 (rue Lan ici) partie lot 177 (boul.Ste-Croix) 195-20 (rue Legault) 195-P-37, 195-38A et partie 195 (rue des Rivières) 195-52 (rue Noël) 195-81 et partie 195 (rue Bouchard) 197-4, 197-0, 197-7, 197-20, 197-25 (rue Coursol) partie 201 (rue Crystal) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Geneviève; amender l'article 429, par.8 de la Loi des Cités et Villes et faire fixer les montants devant être payés par les propriétaires de terres, pour fins d'aménagement «le pares; amender l'article 463 de la Loi des Cités et Villes et exiger une servitude sur tout immeuble, d'une largeur de 5 pieds pour l'installation de fils aériens ou souterrains ou d'autres services publics; changer le mode «l'imposition des taxes décrétées par les règlements d'emprunt de la « Ville de Pierrefonds » nos 108, 110, 119, 149, 180, 192, 218, 228, 233, 131, 138.109, 173, 188, 196, 197, 202, 248 concernant l'exécution des travaux de certaines conduites principales d'aqueduc, d'égout, de stations de pompage, desservant parties de la ville; amender l'article 537 de la Loi des Cités et Villes pour faire établir de quelle manière et à quelle époque les taxes scolaires peuvent être perçues par le trésorier; et pour autres fins; Pierrefonds, ce 8 mars 1963.Les Procureurs de la requérante, 2403-12-4-o Savard & Rouleau.of sale of the property subject to the substitutions created by the last will and testament of Origène Gobeille executed before J.Camille Paré, n.p., on the 21st day of July, 1938, and such other powers as may be necessary in connection with the said will.Montreal, March 11, 1963.Awaua & Bey, 2346-11-4-o Solicitors for the A pplicanis.Town of Pierrefonds Notice is hereby given that the \"Town of Pierrefonds\", in the county of Jacques-Cartier, will apply to the Provincial Legislature at its present session, for the adoption of an act, the objects thereof are the following: to form in a city corporation the inhabitants and the tax payers on the territory of the town of Pierrefonds; to have the town declared owner à toutes fins que de droit of the following lots possessed and utilized as public streets lots Nos 23-1 (Hortie Street) 150-9.151-51, 151-52.151-53, 152-52 (Rive Boisée Street) 151-55, 152-55 (du Docteur Street) 151-79 (David Street) 151-54, 151-90 (des Maçons Street) part lot 177 (Laniel Street) part lot 177 (Ste-Croix Blvd) 195-20 (Legault Street) 195-P-37, 195-38A and part 195 (des Rivières Street) 195-52 (Noël Street) 195-81 and part 195 (Bouchard Street) 197-4, 197-6, 197-7, 197-26, 197-25 (Coursol Street) part 201 (Crystal Street) of the cadastre of the parish of Ste-Geneviève; to amend section 429 par.8 of the Cities antl Towns Act to fix the amounts to be paid by the owner of lands for the purpose of establishing public parks; to amend section 463 of the Cities and Towns Act to require a right-of-way of 5 feet width on any immoveable, for the installation of overhead and underground wires or anyothcr public services; to change the mode of imposition of the taxes provided for by borrowing by-laws of the \"Town of Pierrefonds\", Nos 108, 116, 119, 149, 186, 192, 218, 228, 233, 131, 138, 169, 173, 188, 196, 197, 202, 248 concerning the execution of works of certain water-mains, trunk sewers, and of pumping stations servicing parts of the town; to amend section 537 of the Cities and Towns Act to establish the time and manner of collection of school taxes by the treasurer; ami for any other purpose.Pierrefonds, March 8, 1963.Savard & Rouleau, 2403-12-4-o Attorneys for the petitioner.Examen du Barreau Bar Examination Barreau de Québec \u2014 Bar of Quebec Candidat pour l'admission a l'étude du droit Candidate tor the admission to thb study of law Nom\tPrénom\t\tRésidence\tCollège \t\tAge\t\u2014\t\u2014 Name\tGiven name\t\tResidence\tCollege \tRonald-Gilles.\t23\t1240, Osanam, Québec.\tUniversité d'Ottawa.\t\t\t\t Québec, le 28 mars 1963 \u2014 Quebec, March 28, 1963.Le Secrétaire-trésorier adjoint du Barreau de Québec, Lucien Lortie, 2583-o Associais Secretary-Treasurer of Quebec Bar. 1740 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.6 avril 1963, Tome 96, So IL Liquidation \u2014 Avis de Winding up Notices Coopérative du Bas Perfection Inc.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale des membres du syndicat coopératif « Coopérative du Bas Perfection Inc.», tenue à Saint Jean, le 13 septembre 1902.il a été résolu que les affaires «le ladite société soient liquidées volontairement, et «pie celle-ci soit dissoute, le tout conformément aux dispositions «le la L>i «les syndicats coopératifs «le Québec (Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 290) et «le la Loi «le lu liipiidation volontaire des compagnies à fonds social (Ibid., chapitre 278), et que M.Maurice Bernu-r u été nommé liquidateur.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 29 mars 1903.Le Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douville.2560-o 723-50 G.L.Dante Construction Inc.Avis est par les présentes donné que, le 6 juillet 1902, les actionnaires «le la compagnie « (J.L.Dante Construction Inc.», ont régulièrement adopté une résolution déclarant que les affaires de la compagnie seront liquidées volontairement et que la compagnie sera dissoute, le tout conformément aux dispositions de la Loi «le la liquidation volontaire «les compagnies à fonds social (Statuts refondus de Québec, 1941.chapitre 278).Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2 avril 1963.Le Soux-xecrêtaire de la province, Raymond Douville.2507-o 14647-61 Coopérative du Bas Perfection Inc.Notice is hereby given that at a general meeting of the members of the cooperative syndicate \"Coopérative «lu Bas Perfection Inc.\", held at Saint-John's, on September 13, 1962, a resolution was adopted to the effect that the affairs of the said association be wound up voluntarily, and that it be dissolved, in accordance with the provisions of the Quebec Cooperative Syndicates Act, Revised Statutes of Quebec.1941, chapter 290) and the Winding-up Act, (Ibid., chapter 278), ami that Mr.Maurice Bernier has been appointed liquidator.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, on March 29.1963.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2566 723-56 G.L.Dante Construction Inc.Notice is hereby given that, on July 6,1962, the shareholders of \"G.L.Dante Construction Inc.\", adopted a resolution, in the regular manner, declaring that the affairs of the said company be wound up voluntarily, and that the company be dissolved, the whole pursuant to the provisions of the Winding-up Act (Revised Statutes of Quebec.1941.chapter 278).Given at the office of the Provincial Secretary, on April 2, 1963.Raymond Douville, Axxixtant Secretary of the Province.2567 14647-61 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Village d'Ayersville Avis public est par les présentes donné, tel que prescrit par l'article 39 de la Loi de la Commission municipale de Québec (Statuts refondus de Québec, 1941, chapitre 207), que la Commission municipale «le Québec présentera, conformément aux dispositions de l'article 38 de ladite loi, à un juge de la Cour supérieure siégeant à Saint-Jérôme, dans et pour le district de Saint-Jérôme, mardi, le 16 avril 1963, à 10 heures a.m., une requête aux fins de faire déclarer en défaut au sens «le la section V de la même loi la corporation du village d'Ayersville, dans le comté d'Ar-genteuil.Québec, ce 27 mars 1903.Le Secrétaire, 2572-0 Roger Desaulniers.Canton de Magog Le soussigné donne avis, que, tel que demandé dans une résolution adoptée le 5 mars 1963 par le conseil municipal du canton de Magog, comté de Stanstead, et conformément aux dispositions de l'article 131 -A du Co«le municipal, il a révoqué, en date du 26 mars 1963, le décret émis par le gouverneur-général en conseil le 25 septembre 1855, ordonnant que les publications de tous les Village of Ayersville Public notice is hereby given, as prescribed by section 39 of the Quebec Municipal Commission Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 207), that the Quebec Municipal Commission will present, pursuant to the provisions of section 38 of the sai«l act, to a judge of the Superior Court sitting at Saint-Jérôme, in and for the district of Saint-Jérôme, Tuesday, April 16, 1963, at 10:00 o'clock a.m., a petition for the purpose of declaring in default under section V of the same Act the corporation of the village of Ayersville, in the county of Argenteuil.Quebec, March 27, 1903.Roger Desaulniers, 2572 Secretary.Township of Magog The undersigned gives notice that, as requested in a resolution adopted on March 5, 1903, by the municipal council of the township of Magog, county of Stanstead, and pursuant to the provisions of section 131-A of the Municipal Code, the council has revoked, on March 20, 1963, the decree issued by the Governor-General in Council on September 25, 1855, ordering that the publi- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 6, 1668, Vol.96, So.1.', 1741 avis publics, règlements, resolutions ou ordres de la corporation précitée se fasse dans la langue anglaise seulement.Le présent avis est publié en vertu de l'article 131-A du Code municipal.Le Ministre des Affaires municipales, 2572-o Pierre Laportk.Ministère de l'Agriculture Industrie laitière Ordonnance No 5-62-B Région du Sud de la province de Québec Extrait des procès-verbaux des séances de la Commission de l'Industrie Laitière de la province de Québec.Séance du jeudi, 28 mars 1963, tenue au bureau de la Commission de l'Industrie Laitière à Montréal à 10 heures du matin.Présents: MM.Nolasque April, président, Paul-Abel Ares, Cyril-E.Dahms, Paul Charette, commissaires, Alphonse Savoie, secrétaire, et Charles-A.Gamache, en., conseiller juridique.La Commission décrète ce qui suit: 1° L'article 2 de l'ordonnance 5-62 publiée dans la Gazette officielle de Québec du 25 août 1962, est modifié en ajoutant, après les mots i les districts électoraux de » les mots « Beauce, Mégantic, Frontenac, Wolfe, Compton ».2° La présente ordonnance entrera en vigueur le 16 avril 1963.Signé: Nolasque April, président, Paul-Abel Ares, commissaire, Cvhil-E.Dahms, commissaire, Paul Charette, commissaire.Certifié: Alphonse Savoie, secrétaire.2589-0 Département de l'Instruction publique Bcllerive Avis est par la présente donné, que je me propose de soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux dispositions de l'article 71-B, du chapitre 59, des Statuts refondus de Québec, 1941, l'annexion du territoire actuel de la commission scolaire de Bellerive, dans le comté de Labelle, à la municipalité scolaire de Nominingue, dans le même comté.Québec, le 20 mars 1903.Le Surintendant de VInstruction publique, O.-J.Desaulniers.2463-13-2-o 102-63 Petit-Pabos Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de Petit-Pabos, dans le comté de Gaspé-Sud, à la municipalité scolaire de Pabos, dans le même comté.Québec, le 26 mars 1963.Le Surintendant de V Instruction publique, O.-J.Desaulniers.2506-13-2-o 454-56 cation of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the above mentioned corporation be made in the English Language only.The present notice is published under section 131 -A of the Municipal Code.Pierre Laporte, 2572 Minister of Municijtal Affairs.Department of Agriculture Dairy Industry Order No.5-62-B Region of Southern Quebec Province Excerpt from the proceedings of the meetings of the Dairy Industry Commission of the Province of Quebec.Meeting of Thursday, March 28.1963, held in the office of the Dairy Industry Commission in Montreal at 10:00 o'clock in the morning.Present: Messrs.Nolasque April, President, Paul-Abel Ares, Cyril-E.Dahms, Paul Charette, Commissioners, Alphonse Savoie, Secretary, and Charles-A.Gamache, q.c, Legal Adviser.It is enacted as follows: 1.Section 2 of Order 5-62 published the in Quebec Official Gazette of August 25, 1962, is modified by adding, after the words \"the electoral districts of\" the words \"Beauce, Mégantic, Frontenac, Wolfe, Compton\".2.The present Order shall come into force on April 10, 1963.Signed: Nolasque April, President, Paul-Ahel Ares, Commissioner, Cyril-E.Dahms, Commissioner, Paul Charette, Commissioner.Certified: Alphonse Savoie, Secretary.2589-o Department of Education Bellerive Notice is hereby given that I intend to submit to the Lieutenant-Governor in Council, pursuant to the provisions of section 71-B of chapter 59 of the Revised Statutes of Quebec, 1941, the annexation of the present territory of the school commission of Bellerive, in the county of La-belle, to the school municipality of Nominingue, in the same county.Quebec, March 20, 1903.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.2463-13-2 102-63 Petit-Pabos Application is made to annex the present territory of the school commission of Petit-Pabos, in the county of Gaspé-South, to the school municipality of Pabos, in the same county.Quebec, March 26, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.2500-13-2 454-56 1742 GAZETTE OFFICIELLE DE QVEllEC, 6 avril IMS, Tome 95, No 14 Paroisse St-Michel-de-Rougemont Demande est faite d'annexer le territoire actuel de la commission scolaire de la paroisse de St-Michel-de-Rougemont, dans le comté de Rouville, à la municipalité scolaire du village de St-Michel-de-Rougemont, dans le même comté.Québec; le 26 mars 1963.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.desaulniers.2507-13-2-o 360-01 Montbeillard et Rollet Avis est par la présente donné que je me propose de révoquer l'union des corporations de syndics d'écoles pour les municipalités de Montbeillard et de Rollet, dans le comté de Rouyn-Noranda, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 108, du chapitre 59, des Statuts refondus de Québec, 1941.Québec, le 27 mars 1903.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Dehai i.mkiis, 2532-14-2-o 1329-61 Val-Jalbcrt Avis est par la présente donné que je me propose de soumettre au lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux dispositions de l'article 71-B, du chapitre 59, des Statuts refondus de Québec, 1941.l'annexion du territoire actuel de la municipalité scolaire de Val-Jalbert.dans le comté de Roberval, à la municipalité scolaire de Chambord, dans le même comté: Le territoire en question comprend premièrement, la partie du lot 21 du rang I, située à l'ouest de la rivière Ouiatchouan; la partie des lots 21 et 22 du rang II, située .à l'ouest de la même rivière ainsi qu'une partie du lot 23 du rang II bornée à l'est par le lot No 22, à l'ouest au prolongement vers le sud jusqu'au rang III de la ligne de division, des lots 21 et 22 du rang I, tous ces lots ou parties de lots du canton Charlevoix, et deuxièmement, cette autre partie du lot No 21, à l'est de la rivière Ouiatchouan du rang I, le lot No 20-c du même rang et une partie du lot 20-b du même rang comprise entre le lot 20-c à l'ouest et bornée encore à l'est au prolongement vers le nord jusqu'au Lac Saint-Jean de la ligne separative des lots Nos 20 et 21 du rang II, et la partie à l'est de la rivière Ouiatchouan des lots Nos 21 et 22 du rang 2, tous du même canton.Québec, le 27 mars 1903.Le Surintendant de l'Instruction publique, O.-J.Desaulniers.2533-14-2-0 504-60 Parish of St-Michel-de-Rougemont Application is made to annex the present territory of the school commission of the parish of St-Michel-de-Rougemont, in the county of Rouville, to the school municipality of the village of St-Michel-de-Rougemont, in the same county.Quebec, March 20, 1903.O.-J.desaulnier8, Superintendent of Education.2507-13-2 3G0-01 Montbeillard and Rollet Notice is hereby given that I intend to revoke the Union of the School Sydicates Corporations for the municipalities of Montbeillard and of Rollet, in the county of Rouyn-Noranda, in accordance with the provisions of the last paragraph of section 108 of chapter 59, in the Revised Statutes of Quebec, 1941.Quebec, March 27, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.2532-14-2 1329-61 Val-Jalbert Notice is hereby given that I intend to submit to the Lieutenant-Governor in Council, pursuant to the provisions of section 71-B of Chapter 59, of the Revised Statutes of Quebec, 1941, the annexation of the present territory of the school municipality of Val Ja bert, in the county « f Roberval, to the school municipality of Chambord, in the same county: The territory in question comprises, first, the part of lot 21 on Range I situated to the west of Ouiatchouan River; the part of lots 21 and 22 on Range II, situated to the west of the same river as well as a part of lot 23 on Range II bounded on the east by lot No.22, on the west by the extension towards the south as far as Range III of the division line between lots 21 and 22 on Range I; all these lots or parts of lost in the township of Charlevoix, and, secondly, the part of lot No.21, to tl e east of the Ouhtchouan River on Range I, the lot No.20-c on the same Range and a part of lot 20-b on the same Range enclosed between lot 20c on the west and bounded on the east by the extension towards the north as far as lake St.John of the line separating lots Nos.20 and 21 on Range II, ami the part to the east of the Ouiatchouan River of lots 21 and 22 on Range 2, all in the same township.Quebec, March 27, 1963.O.-J.Desaulniers, Superintendent of Education.2533-14-2 504-60 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Canton de Girard Cadastre officiel du canton de Girard, municipalité de St-Thomas Didyme, division d'enregistrement de Lac St-Jean-Ouest.Avis est par la présente donné que les lots 14-2-2, 14-2-5, 14-2-6, sont annulés en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 15 mars 1963.Le Sous-ministre, 2549-0 Fernand Boutin.Township of Girard Official cadastre of the township of Girard, municipality of St-Thomas Didyme, registration division of Lac St-Jean-Ouest.Notice is hereby given that lots 14-2-2, 14-2-5, 14-2-6 are cancelled in virtue of article 2174A, of the Civil Code.Quebec, March 15, 1963.Fernand Boutin, 2549-o Deputy Minister. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 6, 1.063, Vol.m.So.Il 1743 Paroisse de Lachine Cadastre officiel de la paroisse de Lachine, municipalité de la cité de Lasalle, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 944, 945, 946, 947 et 947-1 est annulée et le lot 1070 est ajouté en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 19 mars 1903.Le Sous-ministre, 2549-o Fernand Boutin.Parish of Lachine Official cadastre of the parish of Lachine, municipality of the city of Lasalle, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots a part of lots 944.945, 940, 947 and 947-1 is cancelled and lot 1070 is added in virtue of article 2174A, of the Civil Code.Quebec, March 19, 1963.Fernand Boutin, 2549-o Deputy Minister.Paroisse de Montréal Cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, municipalité de la cité de Westmount, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 4753 est ajouté en vertu de l'article 2174A, du Code civil.Québec, le 19 mars 1963.Le Sous-ministre, 2549-o Fernand Boutin.Parish of Montreal Official cadastre of the municipality of the parish of Montreal, municipality of the city of West* mount, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 4753 is added in virtue of article 2174A, of the Civil Code.Quebec, March 19, 1903.Fernand Boutin, 2549-o Deputy Minister.Paroisse de Ste-Foye Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Foye, municipality de la cité de Ste-Foy, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné «pic les lots 17-8 et 18-67 sont annulés en vertu «le l'article 2174A, «lu Code civil.; Québec, le 21 mars 1963.Le Sous-ministre, 2549-o Fernand Boutin.Parish of Ste-Foye Official cadastre of the parish of Ste-Foye, municipality of the city of Ste-Foy, registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 17-8 ami 18-67 are cancelled in virtue of Article 2174A.of the Civil Co«lc.Quebec.March 21, 1963.Fernand Boutin, 2549-0 Deputy Minister.Paroisse de Ste-Foye Cadastre officiel «le la paroisse «le Ste-Foye, municipalité de la cité «le Ste-Foy, division d'enregistrement «le Québec.Avis est par les présentse donné que les lots 224-145 et 224-158 sont annulés en vertu de l'article 2174A.«lu Code civil.Québec, le 22 mars 1963.Le Sous-ministre, 2549-o Fernand Boutin.Parish of Ste-Foye Official cadastre of the parish of Ste-Foye, municipality of the city «)f Ste-Foy, registration division of Quebec.Notice is hereby given that lots 224-145 and 224-158 are cancelled in virtue of Article 2174A, of the Civil Cof Article 2174A, of the Civil Code.Quebec, March 19, 19G3.Fernand Boutin, 2549-o Deputy Minister.Ministère du Travail Avis de modification Coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames Région de Québec Conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la Loi de la convention collective (S.R.Q., 1941, chapitre 163 et amendements), l'honorable Department of Labour Notice of amendment Men's and ladle's hairdressing trades Region of Quebec Pursuant to the procedure established under section 8 of the Collective Agreement Act (R.S.Q., 1941, chapter 163 and amendments), the Honour- 1744 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 6 avril 1963, Tome 95, So I/, Rent' llamcl.ministre du Travail, donne avis par les présentes, qu'il a l'intention de soumettre à l'appréciation et a la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les mollifications suivantes au décret numéro 44 du 14 janvier 1954 et amendements, relatif aux métiers de coiffeur pour hommes et coiffeur pour dames dans la région «le Québec, à savoir: 1° Le Syndicat Catholi«|ue «les Harbiers, Coiffeurs et Coiffeuses «le Rimouski sera biffé des parties contrat-tantes «le deuxième part.2° Loi nuits « la ville de Rimouski et un rayon «le cinq (5) milles se ses limites » seront biffés du paragraphe 2° «le l'article 101°.3° L'alinéa « e » «lu paragraphe intitulé « Zone II » «le l'article 102° sera biffé.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication «lans la Gazette officielle de Québec.Durant les trente jours ù compter de la «late de publication «le cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable Ministre du Travail recevra les objections en «louble copie, si possible, que les intéressés pourront délirer formuler.Le Sous-ministre du Travail, GÉBABO Themhlay.Ministère du Travail, Québec, le 6 avril 19(53.2550-o able René Humel, Minister of Labour, hereby gives notice, that he intends to submit to the consideration ami decision «>f the Lieutenant-Governor in Council the following amendments to the «lecree number 44 of January 14, 1954 ami amendments, relating to the men's and ladie's hairdressing trades in the «listrict of Quebec, to wit: 1.\"I/c Syndicat Catholiiiue des Barbiers, Coiffeurs et Coiffeuses de Rimouski\" will be deleted from contracting parties of the second part.2.The words \"the town of Rimouski and a a radius of five (5) miles from its limits\" will be deleted from paragraph 2 of article 101.3.Sub-paragraph \"e\" of the paragraph entitled \"Zone II\" of article 102 will be deleted.The publication of the present notice does not render obligatory the provisions contained therein.Such provisions, with or without amendments, can only be rendered obligatory by an Order in Council which conn's into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.During the thirty days following the date of publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister «>f Labour will consider the objections, in duplicate, if possible, which the interested parties may wish to set forth.(.KHAKI) TltEMRLAY, Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Quebec, April 0, IMS'.2550-o Nominations Appointments Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commissions sous le grand sceau de la province, les nominations suivantes: Québec, le 20 février 1963.MM.Gérard Juneau, garagiste, Johnny Bergeron, rentier, Antonio Allait!, commerçant, et Maurice Bergeron, cultivateur, tous de St-Paulin: commissaires pour tenir la Cour des commissaires de St-Paulin, dans le district électoral de Maskinongé.Québec, le 5 mars 1963.M.Jean-Claude Royer, conseiller juridique au ministère des Affaires culturelles: commissaire per de dim us post est ut cm.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2 avril 1963.Le Sous-secrétaire de la province, 2517-o Raymond Douville.Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make, by Commission, under the Great Seal of the Province, the following appointments: Quebec, February 26, 1963.Messrs.Gérard Juneau, garageman, Johnny Bergeron, annuitant, Antonio Allard, tradesman, and Maurice Bergeron, farmer, all of St-Paulin; commissioners to hold the Commissioners Court of St-Paulin, in the electoral district of Maskinongé.Quebec, March 5, 1963.Mr.Jean-Claude Royer, juridical counsellor to the Minister of Cultural Affairs: Commissioner per dedimus postestatem.Given at the office of the Provincial Secretary, on April 2, 1903.Raymond Douville, 2517 Assistant Secretary of the Province.Il a plù à son Honneur le lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil exécutif, par commissions Sous e Grand Sceau, de faire, pour remplir la charge de président p'élection, les nominations suivantes: District electoral Nom, prénoms Electoral district Name, christian names Deux-Montagnes.Lécuyer, Réal (1).Montréal-Verdun.Berlinguette, Richard (2).His Honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the executive Council to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning-officcr, the persons whose name follows: Profession on occupation Domicile Profession or calling Domicile Secrétaire \u2014 Secretary.Saint-KiiHtache-sur-le-Lac.Gérant de ventes \u2014 Sales manager.Montréal.(1) En remplacement de monsieur Luc l6veillé, démissionnaire.\u2014 In place of|Mr.Luc|Léveillé, resigner.(2) En remplacement de monsieur Anatole Lesyk, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Anatole Lesyk, résigner. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 6, IMS, Vol !>6.So, I', 1745 Québec, le 27 mars 1903.lit Président général des élections, 2573-o François Drouin, ch.Quebec.Mardi 27.1903.François Drouin, q.c, 2573-0 Ch ief Return ing-Officer.Il a plû à son Honneur le lieutenant-gouverneur, «le l'avis et du consentement du Conseil exécutif, par commissions Sous le (ïrand Sceau, de faire, pour remplir la charge de président d'élection, la nomination suivante: His Honour the Lieutenant-Governor has 'been pleased, with the advice and consent of the executive Council to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning-officer, the person whose name follows: District électoral Electoral district\tNom, pi ennuis Name, christian naines\tPretension Oil occupation Profession or calling\tDomicile Domicile Gaspé-Sud.\tFraser.Ernest (1).\tContremaître \u2014 Foreman.\tChandler.(1) En remplacement de Michael Smith, démissionnaire.\u2014 In place of Mr.Michael Smith, resigner.Québec, le 29 mars 1903.Le Président général des élections, 2573-o François Drouin, cr.Quebec, March 29, 1903.François Drouin, q.c, 2573-0 Chief Retuming-Officer.Soumissions Tenders Ville de Bedford Comté de Missisquoi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées * Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Emile E.Deniers, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 1.rue Principale, Bedford, comté de Missisquoi, jusqu'à 7.30 heures p.m., mardi, le 23 avril 1903, pour l'achat de $87.500 d'obligations de la ville de Bedford, comté de Missisquoi, datées du 1er mai 1963 et remboursables par séries du 1er mai 1964 au 1er mai 19S3 inclusivement, avec intérêt à un aux non inférieur à 5%, ni supérieur à 6%, payable semi-annucllement les 1er novembre et 1er mai de chaque année.Le taux d'intértH peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Règlement No.150 \u2014 2e et dernière tranche «le $87,500 \u2014 construction d'un aqueduc et réseau d'alimentation d'eau potable.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1963.Tableau d'amortissement \u2014 $87,600 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1964.$ 500 1er mai 1905 .500 1er mai 1900 .500 1er mai 1907 .500 1er mai 1908.500 1er mai 1909.1,000 1er mai 1970.1,000 1er mai 1971.1,000 1er mai 1972.1,000 1er mai 1973.1,000 1er mai 1974.1,500 1er mai 1975.1,500 1er mai 1970.1,500 1er mai 1977.1,500 1er mai 1978.1,500 1er mai 1979 .2,000 1er mai 1980 .2,000 1er mai 1981.2,000 1er mai 1982 .2,000 1er mai 1983.04,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération Town of Bedford County of Missisquoi Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bomls\" will be received by the undcrsignetl Emile E.Deniers, secretary-treasurer, town hall, 1 Main St., Bedford, county of Missisquoi, until 7:30 o'clock p.m.on Tuesday, April 23, 1963, for the purchase of an issue of $87,500 of bonds for the town of Bedford, county of Missisquoi, dated May 1, 1963, and redeemable serially from May 1, 1964 to May 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%, nor more than 6%, payable semi-annually on November 1 and May 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-law No.150 \u2014 2nd and last block of $87,-500 \u2014 construction of an aqueduct and a drinking-water pijiefinc system.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from May 1, 1963.Table of redemption - 987,500 \u2014 20 years Year Capital Mav 1, 1964.$ 500 May 1, 1905.500 May 1, 1966.500 May 1,1907 .500 Mav 1, 1908 .500 Mav 1, 1969.1,000 May 1, 1970.1,000 May 1, 1971.1,000 May 1, 1972.1,000 Mav 1, 1973.1,000 May 1, 1974.1,500 May 1, 1975.1,500 May 1, 1970.1,500 May 1, 1977.1,500 May 1, 1978.1,500 Mav 1, 1979.2,000 May 1, 1980 .2,000 May 1, 1981.2,000 May 1, 1982 .2.000 May 1, 1983 .04,500 Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen- 1710 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 6 avril 1963, Tome 95, No /,', pour (1rs obligations à courte échéance dix ans ou à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bedford, comté de Missisquoi.I>e capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales, dans la province de Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Lesditcs obligations ne seront pas rachetai des par anticipation.Chaque soumission devra être accompugnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 23 avril 1963 à 7.30 heures, du soir, à l'Hôtel de Ville, 1, rue Principale, Bedford, comté de Missisquoi.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bedford, (Comté de Missisquoi), ce 29 mars 1963.Le Secrétaire-trésorier, Emile E.Dkmkks.Hôtel de Ville, 1, rue Principale, C.P.195, Bedford, (Missisquoi), P.Q.Téléphone: CH 8-2440.2502-o year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if anv, by certified cheque payable at par at Bedford, county of Missisquoi.Capital and interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must l>e accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the Council, to be held on Tuesday, April 23, 1903, at 7:30 o'clock p.m., in the town Hall, 1 Main St., Bedford, county of Missisquoi.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Bedford, (County of Missisquoi), March 29, 1903.Emile E.Demers, Secretary-Treasurer.Town Hall, 1 Main St., P.O.B.195, Bedford, (Missisquoi), P.Q.Telephone: CH 8-2440.2502 La commission des écoles catholiques de Québec Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront, reçues par le soussigné Eug.Huot.secrétaire-trésorier.1400, chemin Saint e-Foy.Québec 6.jusqu'à midi, heure normale de l'Est, jeudi, le 25 avril 1963, pour l'achat de 83.000,000 d'obligations de La Commission des écoles catholiques de Québec, datées du 1er mai 1963 et remboursbales par séries du 1er mai 1964 au 1er mai 1983 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 5%, ni supérieur à ©%, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les échéances.Résolution d emprunt 10704 en date du 20 mars 1903; consolidation du déficit accumulé.le 30 juin 1962, constructions d'écoles et achat «le mobilier scolaire.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter «lu 1er mai 1963.Tableau d'amortissement \u2014 $3,000,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er mai 1964.S 86,000 1er mai 1905 .91,000 1er mai 1966 .90,000 1er mai 1967.101,000 1er mai 1968.107.000 1er mai 1909.112.000 1er mai 1970.119,000 1er mai 1971.125,000 1er mai 1972.132,000 1er mai 1973.139,000 1er mai 1974.147,000 1er mai 1975.155,000 1er mai 1970.163,000 1er mai 1977.172,000 The catholic school commission of Quebec Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Eug.Huot, secretary-treasurer, 1460 Ste-Foy Road, Quebec 0, until twelve o'clock, Eastern standard time, on Thursday, April 25, 1903, for the purchase of an issue of $3,000,000 of bonds for The catholic school commission of Quebec, dated May 1, 1903, and retleemable serially from May 1, 1964 to May 1, 1983 inclusively, with interest at a rate not less than 5%,.nor more than 6%, payable semi-annually on May 1 and November 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.Loan resolution 10704 dated March 20, 1903; funding of the accumulated deficit as at June 30, 1962, buildings of schools and purchase of school furniture.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from May 1, 1963.Table of redemption \u2014 $3,000,000 \u2014 20 years Year Capital May 1, 1964.$ 86,000 May 1, 1905.91,000 May 1, 1966.96,000 May 1,1907.101,000 May 1, 1908.107,000 May 1, 1909.112,000 May 1,1970.119,000 May 1, 1971.125,000 May 1, 1972.132,000 May 1, 1973.139,000 May 1, 1974.147,000 May 1, 1975.155,000 May 1, 1976.163,000 May 1, 1977.172,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1968, Vol.95, So.14 1747 1er mai 107S.$182,000 ler mai 1979.192.000 1er mai 1980.203.0(H) 1er mai 1981.214,000 1er mai 1982 .220.000 1er mai 1983 .238.000 On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursai îles suivant le tableau «l'amortissement tel «pie ci-dessus, et «pie |ea offres «pli seront faites pour «les obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intends courus, s'il y a lieu, par chèque payable au pair à Québec.Le capital et- les intérêts sont payables à Unîtes lee succursales, «lans la province de Québec, «le la banque dont le nom est mentionné dans la proctnlurc d'emprunt, ainsi «pi'aux succursales «le ladite ban«pic à Toronto et à Ottawa, «lans la province d'Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumissions devra être accompagnée «l'un chèque visé égal à 1% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvo considered for one «'f the three terms only.Adjudication shall Ik* made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and BOCrued interest, if any, by certified cheque payable nt par at Alma.Capital and interest are payable nt all the branches in the Province «>f Quebec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not Ik- redeemable by anticipation.Each tender must l>e accompani«| by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue ami must specify whether interest accrued on the bonds fo the «late of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened ami considered at a meeting of the council to lie held on Monday, April 22.1963, at k:00 o'clock p.m.at the College Hall, St-Léon-f May 1963, unless same shall be called for before that «late and all charges paid there«m.Quebec.Que.Mardi IS.1963.Canadian Pacific Express Company, K.II.Nkwi.vukii, 2404-12-C-o General Superintendent.Sales by Licitation Meilleur vs Charpentier et al Province «>f Quebec, «listrict of Montreal, Superior Court, No.581 997, Irène Meilleur, plaintiff, vs Maurice Charj>cntier et al, defendants, and The Minister of National Revenue of Canada et al, mis en cause es quality.Notice of licitation Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting in Montreal, in the district of Montreal, and rendered by the Honourable Justice Maurice Archambault, on the 21st day of December 1902, in a case in which Irène Meilleur, spinster, housewife, of the city and district of Montreal, is plaintiff, and Maurice, André, Dollard, Claude, Marcel, Robert and Jacques Charpentier and Jeannine Charpentier, spinster, all of the city and district of Montreal, are defendants, and The Minister of National Revenue of Canada, acting on behalf of the Canadian Government, in the name of Her Majesty the Queen, Division of Succession Duties, and The Minister of Finance of the Province of Quebec, acting on behalf of the Provincial Government, Division of Succession Duties, are mis en cause es quality, ordering the licitation of the immoveable described as follows: An emplacement or immoveable known under number three hundred and sixty-five (365) on the official plan and book of reference of the Ste-Marie Ward with a building thereon erected bearing civic numbers 1199 to 1207 Plessis Street and 1204 to 1210 Dalcourt Street, in the city of Montreal; The above described immoveable will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidder, on the TWENTY-THIRD day of APRIL 1963, at HALF past TEN o'clock in the forenoon, in Room No.31, in the Court House of Montreal, or in any other room as circumstances may require, the said sale to be made subject to the charges, clauses and conditions mentioned in the list of charges filed in the office of the pro-thonotary of the Superior Court.Any opposition to annul, to secure charges or to withdraw to be made to the said licitation must be filed in the office of the prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication and any oppo- 1754 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 0 avril 1908, Tome 95, No 14 déposée dans les six jours après l'adjudication; et à défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par les présentes, elles seront forcloses du droit de le faire.Un déjrôt de trois mille dollars ($3,000) sera exigé avant la vente tie tout offrant ou enchérisseur.Montréal, 11 mars 1903.Lea Procureurs de la demanderesse, 2330-1 l-2-o (ionthikii & Bernier.Ferland vs Lehouillicr et al Province tie Québec, district de Beauce, Cour Supérieure, No: 29-147.Ferlant!, demandeur m Lehouillicr et al, défendeurs.Avis de licitation Avis est donné qu'en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure siégeant à St-Joseph tie Beauce, district de Beauce, le premier jour d'octobre 1902, dans la cause ci-dessus, ordonnant la licitation de l'immeuble ainsi décrit: « Un emplacement situé en le village de Ste-Marie-Beauce, sur la route Carter, d'un arpent de front sur un arpent et trois-quart de profondeur, plus ou moins, avec bâtisses, circonstances et dépendances, connu et < lésigne sous le numéro quatre cent trente-six (No 430) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre pour la paroisse de Ste-Marie de Beauce, sauf et à distraire la partie vendue à Jean-Baptiste Carter.» L'immeuble ci-dessus désigné sera mis â l'enchère et adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur, le DEUXIÈME jour de mai 1963, à DIX heures a.m., au bureau du Protonotaire, au palais de justice à St-Joseph tie Beauce, sujet aux charges, clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de ladite Cour; et que toute opposition â fin d'annuler, à fin de charge ou à fin de distraire à ladite licitation devra être déposée au greffe du Protonotaire de ladite Cour au moins douze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication et que toute opposition à fin de conserver devra être déposée dans les six jours après l'adjudication; et, â défaut par les parties de déposer lesdites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.Un dépôt de cent dollars ($100.00) sera exigé avant la vente de tout offrant ou enchérisseur.Ste-Marie de Beauce, ce 18 mars 1963.Le Procureur du demandeur, 2417-12-2-o Louis-Alfred Ferland.sit ion for payment must be filed within six days following the adjudication; and failing the interested parties to file the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from so doing.A deposit of three thousand dollars ($3,000) shall be exacted before the sale, from each and every bidder.Montreal, March 11, 1903.(iONTIIIER & BeRNIER, 2330-11 -2-o Attorneys for Plaintiff.Ferland va Lehouillier et al Province of Quel>ec, district of Beauce, Superior Court, No.29-147.Ferland, plaintiff, vs Lehouillier et al, defendants.Notice of licitation Notice is hereby given that in virtue of a judgment of the Superior Court sitting at St-Joscph tie Beauce, district of Beauce, on the first day of October, 1902, in the above-mentioned case, ordering the licitation of the immoveable (Iescribed thus: \"An emplacement situated in the village of Ste-Marie-Beauce, on Carter Road, measuring one arpent in front, by one and three-quarters arpent in depth, more or less, with the buildings, circumstances antl dependencies, known and designated under number four hundred and thirty-six (No.430) in the official plan and book of reference of the cadaster for the parish of Ste-Marie de Beauce; save and to be withdrawn is the part sold to Jean-Baptiste Carter.\" The immoveable designated above will be sold by auction and adjudged to the highest and last bidtler, on the SECOND day of MAY, 1963, at TEN o'clock a.m.in the office of the prothonotary, in the Court House in St-Joseph de Beauce, subject to the charges, clauses and conditions indicated in the list of charges as filed in the records of the Prothonotary of the said Court; any opposition to annul, to secure charge or to with-draw to be made to the said licitation must be filed in the office of the Prothonotary of the said Court at least twelve days before the day fixed as aforesaid for the sale and adjudication, and any opposition for payment must be filed within six days following the adjudication, and failing, the interested parties, to file the said opposition within the delays hereby limited, they shall be foreclosed from doing so.A deposit of one hundred dollars ($100.00) shall be exacted before the sale from each and every bidder.Ste-Marie de Beauce, March 18, 1903.Louis-Alfred Ferland, 2417-12-2 Attorney for the Plaintiff.Vente \u2014 Loi de faillite Sale \u2014 Bankruptcy Act Camille Thibeault Canada, Province de Québec, district de Rimouski, Cour Supérieure, (Siégeant en matière de Faillite), C.S.No F-165.Dans l'affaire de la Faillite de: Camille Thibeault, garagiste, Causaps-cal, P.Q., failli.Avis de vente à l'encan Avis est par les présentes donné que MARDI, e TRENTIEME jour d'AVRIL 1963, à DEUX Camille Thibeault Canada, Province of Quebec, district of Rimouski, Superior Court (Sitting in a matter of bankruptcy) S.C.No.F-165.In the matter of bankruptcy of Camille Thibeault, garage-keeper, Causapscal; P.Q., brankrupt.Notice of Sale by auction Notice is hereby given that on TUESDAY, the THIRTYTH day of APRIL, 1963, at TWO QUEBEC OFF ICI AO GAZETTE, April 6, /.%'.?, Vol !i.5, .Xo.H 1755 heures de l'après-midi, sera vendu par encan public à la porte de l'église paroissiale de Causapscal, l'immeuble de cette faillite, comme suit: Lot numéro quatre-A-vingt-neuf (4-A-29) du cadastre officiel, du rang un (1) nord, du canton < 'asuspscull, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Cet immeuble sera offert en vente au plus haut et dernier enchérisseur.Les titres et certificats peuvent, être examinés en tout temps en s'adressant au syndic soussigné.Cette vente est faite conformément aux articles 716, 717 et 719A du code des procédures civiles et aussi à l'article 55 de la Loi de Faillite; cette vente équivaut à la vente au shérif, avec l'effet du décret, et faite conformément au jugement rendu par Monsieur J.Bte Desjardins, régistraire des faillites.Condition de paiement: comptant.Rimouski, ce 21e jour de mars 1963.Le Syndic licencié, Hknri-A.Martin.160 de l'Êvêché, Rimouski, P.Q.2483-13-2-o Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province de Quebec District de Beaubarnois Cour Supérieure, f THE PRUDENTIAL IN-NoG529.\\ A SURANCE COMPANY vOF AMERICA, une compagnie ayant son siège social et sa principale place «l'affairés en la cité de Newark, comté d'Essex, dans les États-Unis d'Amérique; et ayant aussi son siège social pour le Canada, eu la cité de Toronto, province «l'Ontario, et ayant encore sa principale place d'affaires pour la province «le Québec, en les cité et district de Montréal, dûment licenciée en vertu de la Loi «les assurances du Canada, demanderesse m WILLIAM SUMMON, «le la ville «le Châteauguay, et y résidant au No 98, rue «les Tulipes, défendeur.À savoir: « Un emplacement ayant front sur la rue des Tulipes, en la ville «le Châteauguay, connu comme étant la suhivision trente du lot cinquante (50-30) aux plan et livre «le renvoi officiels de la paroisse de St-Joachim de < 'hâteau-guay.Avec la bâtisse dessus érigiV* et por' M le numéro civique, 98, rue des Tulijies.» Pour être vendu â la porte de l'église paroissiale de St-Joachim de Châteauguay, dit district de Beauharnois, le NEUVIÈME jour de MAI, 1963, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Le Shérif, Ernest Poirier.Valleyfield Que., le 27 mars 1903.2530-14-2 [1ère insertion: le 0 avril 1903] Fieri Fada» de Terri» Canada \u2014 Province de Québec District de Beauharnois Cour Supérieure, ( C O CI Ê T É CENTRALE No 580-220.\\ O D'HYPOTHÈQUES ET *DE LOGEMENT, une cor- o'clock in the forenoon, will be sold by public auction at the parochial Church door of Causapscal, the immoveable in this bankruptcy, as follows: Lot number four-A-twenty-nine (4-A-29) in the official cadaster of range one (1) north, in the township of Casuspscull, with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.This immoveable will be offered in sale to the highest and last bidder.The deeds and certificates may be examined at any time by apply to the undersigned trustee.This sale is made pursuant to sections 710, 717 and 719A of the Code of Civil Procedure, and also to section 55 of the Bankruptcy Act; this sale is equivalent to a sheriff's sale, and is made pursuant to a judgment rendered by Mr.J.Bte Desjardins, registrar of bankruptcies.Conditions of payment: cash Rimouski.this 21st day of March, 1963.Henri-A.Martin, Licensed trustee.160 de l'Êvêché, Rimouski, P.Q.2483-13-2 Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BEAUHARNOIS Canada \u2014 Province of Quebec District of Beauharnois Superior Court, (THE PRUDENTIAL IN-No.0529.\"j 1 SURANCE COMPANY ^OF AMERICA, a company having its head office and principal place of business in the city of Newark in the county of Essex, in the United States of America, an«l also having its head office for Canada, in the city of Toronto, Province of Ontario, and also having its principal place of business for the Province of Quebec in the city and district of Montreal, duly licensed under the Insurance Act, of Canada, plaintiff, m WILLIAM SLIM MON of the town of Châteauguay, ami there residing at No.98 des Tulipes Street, defendant.To wit: \"An emplacement fronting on des Tidipes Street, in the town of Châteauguay, known as subdivision thirty of lot fifty (50-30) on the official plan ami book of reference for the parish of St.Joachim de Châteauguay.With the building thereon erected bearing civic number 98 «les Tidipes Street.\" To Ik?s:>1n the southeast by lot G-409-2, on the southwest, by lot G-409-1; measuring on the northwest 38.78 feet, on the northeast 26.04 feet, on the southeast 31.53 feet.«»n the southwest, 25 feet; containing in urea nine hundred ami sixty-nine and five-tenths square feet, (969.5) square feet.Lot No.G-410-2) Of traimzoidal form, hounded on the northwest by the national highway No.15 on the northeast by lot G-158-A.on the southeast, by lot G-409-3.on the southwest, by lot G-410-1; measuring on the northwest 07.80 feet, on the northeast 104.12 feet, on the southeast 38.78 feet, on the southwest 100 feet.Containing in area five thousand three hundred ami twenty-nine square feet (5,329 square feet).With buildings thereon erected, circumstances ami dependencies.\" (Official cadastre for the township of Laval) To be sold at the church o.stcr.s, panel-boards, luminous signs and the establishment of automobile cemeteries along autoroutes and road junctions.1722 449 - Loi de l'impôt sur le revenu et Loi de l'impôt sur les corporations (Plans différés de participation aux bénéfices).1708 449 - Income tax Act and corporation tax Act (Deferred profit sharing plans).1708 492 - Construction, Abitibi-Est et al.1708 492 - Construction, Abitibi-West et al.1708 493-A - Robe, Province.s 1719 493-A - Dress, Province.1719 493-B - Construction, Montréal.1720 493-C - Fer et bronze d'ornementation.Montréal.1721 493-C - Ornament il iron and bronze, Montreal.1721 493-D - Construction, Québec.1721 493-E - Matériaux de construction, Montréal.7121 493-E - Building materials, Montreal.1721 493-F - Commerce de détail.Chieoutimi.1722 AVIS NOTICES Église Baptiste Évangélique de Verdun (L\") - (Requête - Petition).1724 Mountainview Baptist Church (Const - Inc.).1723 Trois-Rivières, par.(Requête - Petition).1723 BILLS BILLS Chartes- Charters \u2014 0 , Abandon de Surrender of Sanctioned.1724 .^T .Sanctionnés 1724 Association Néerlandaise de Montréal Je Maintiendrai (L').1726 COMPAGNIES COMPANIES 5a«ot Construction Inc.1727 .i .r t i \u2022 Compagnie Locale de téléphone de Avis relatif» Notices relative SUulien (La).1726 à la loi des to the Act of Crémerie Sorel Inc.1726 Autorisée Licensed Liberty/Realty Inc.1727 à faire des affaires to do Business Mathieu (Jacques) Inc.1727 St.Catherine-Crescent Development ABCC Finance (Ontario) Limited.1725 Corporation Ltd.1726 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April a, wos.Vol.H6, So.14 Chartes \u2014 Charters \u2014 Abandon de Surrender of (suite) (continued) Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited.1727 Toldi Ltd.1726 United Auto Parts (St-Joseph d'Alma) Ltd.1727 Divers Miscellaneous Ace Metal Strip Ltd.(Dir.).1727 Association of English-Speaking Interns of Montreal (Dir.).1728 Association of English-Speaking Interns of Montreal (Règl- By-laws).1728 Austin Toilet Service Inc.(Dir.).1730 B.T.U.Products Corporation (Dir.).1734 Bétonnière Mont-Bruno Limitée (Dir.).1728 Boisbrillant Realties Inc.(Dir.).1732 Chambre d'Immeubles de Québec (Dir.) 1729 Chambre d'Immeubles de Québec (Ilègl.) 1729 Club de Curling Laval sur le Lac (Le) - (Dir.).1730 Club de Curling Laval sur le Lac (Le) - (Règl- By-laws).1730 Club de la Traction sur Routes (Québec) Inc.(Le) - (RM.).1733 Corporation des Produits B.T.U.(Dir.).1734 Export Corporation (of Canada) Limited (Dir.).1730 Flaury Holdings Inc.(Dir.).7131 Immeubles Boisbrillant Inc.(Les) - (Dir.).1732 Loisirs pour les Handicapés Inc.(Dir.).1731 Loisirs pour les Handicapés Inc.(Règl.).1732 Mon-Mart Discount Department Stores Inc.(Dur.).1729 Motor Truck Club (Quebec) Inc.(The)- (By-laws).1733 Motors Limited (Dir.).1735 Mount Bruno Ready Mix Limited (Dir.) 1728 Northco International Ltd.(Dir.).1731 Quebec Real Estate Board (Dir.).1729 Quebec Real Estate Board (By-laws).1729 Recreation for the Handicapped Inc.(Dir.).1731 Recreation for the Handicapped Inc.(By4aws).1732 Rim Rock Oils Ltd.(Dir.).1729 St.Lawrence Sea Products Co.(Dir.).1733 Sherbrooke Oxygen & Supplies Limited (Dist.: actif - assets).1734 Trois-Rivières Paper Box Ltd (Dir.).1732 United Auto Parts (St-Joseph d'Alma) Ltd (Dist.: actif - assets).1733 Société Jacques Labrecque Limitée (La) - (Dir.).1733 Lettres patentes Letters Patent Abaca Inc.1664 Agences de Publicité Ahuntsic Inc.(Les).1665 Alden Realty Inc.1665 Ameublements St-Jean Limitée.1665 Artisanat Aris-Tocrate Cie Limitée- 1666 Association Commerciale de Roberval Limitée (L').1666 Auberge de France Ltée.1666 Auberge de la Chaumière Inc.1667 Audette Express Inc.1667 Austro-Canadian Electric Co.Ltd.1667 Auto-Air Leasing Limited.1668 Pierre Auto Location Inc.1668 Baby-Snap Ltd.1668 Beaulieu (Paul) Inc.1669 Beau-Pied Shoes Ltd.1674 Beaurepaire Swimming Club.1669 1775 Bel-Air Taxi Inc.1670 Bellemare (Julien) Inc.1670 Bellemure (René) Ltée.1670 Berna ni Development Inc.1671 Bert Électrique Limitée.1671 Boulanger (J.H.) Limitée.1671 Bromont Inc.1672 Bucoviner Relief Association of Montreal.1672 C.P.C.Direct Mailing Ltd.1673 Campeau \u2014 Chomedey Construction Inc.1673 Cartier Plumbing & Heating Inc.1692 Cassette Inc.(La).1673 Central Tobacco Sales Ltd.1674 Centre Commercial «le Repentigny Inc.1674 Chaussures Beau-Pied Ltée (Les).1674 Cie de Construction Cabi (1963) Ltée (La).1675 Cie de Navigation du Golfe Ltée (La).1675 Cie d'Excavation Lajeunesse Ltée (La).1675 Club des Cent Inc.(Le).1676 Club Marco Inc.1676 Club Social des ( i ou nu et s de Chandler.1676 Club Social et Sportif Fais Bien.1677 Clubs de Chasse & Pêche St-Laurent Inc.(Les).1695 Colibri Construction Ltée.1677 Commercial Warehouse Inc.1677 Compagnie Da-Ri Ltée (La).1678 Comptoir Agricole St-Hyacinthe Inc.1678 Corporation Chimique Prudentielle (La) 1679 Courchesne (B.) & Fils Inc.1679 Crands Limited (Correction).1735 Crevier (Lucien) & Fils Limitée.1679 Cuisine Sales Corp.1680 DesBiens Natural Gas Heating Inc.1680 Dominion Ribbon & Carbon Inc.1680 Dorval Delicatessen Ltd.1681 Dubois Holding Corporation Ltd.1681 Eastern Floats Ltd.1681 Édifice Montcalm Inc.1682 Elmwood Steak House Ltd.1682 Entrepôt Commercial Inc.1677 Entreprises Huki Inc.(Les).1682 Francoeur Auto Parts Inc.1683 G.& L.Auto Parts Inc.1683 Genie Gifts Inc.(Correction).1735 Gulf Navigation Co.Ltd.1675 Gendreau (J.Camille) Inc.1684 Giant Holding Corporation.1684 Harvey & Simard Inc.1684 Hôtel Richelieu Motel Inc.1685 Hy Fashions Ltd.1685 Immeubles des Chutes Inc.(Les).1685 Immeubles Rivière-aux-Pins Inc.(Les).1686 Imprimerie-Librairie Côté Limitée.1686 Industries St-Gabriel Inc.(Les).1686 Inter State Paving Inc.1687 Jeunette Inc.1687 Kane Bros Inc.1687 Lahaie (G.) Inc.1688 Paix dans la Montagne Inc.(La).1688 Lecar Ltée.1688 Ligue des Contribuables de Longueuil (La).1689 Marché St.Louis Inc.1689 Montcalm Building Inc.1682 Nasa Enterprises Incorporated.1689 One Hundred Club Inc.(The).1676 P.& D.Transport Inc.1690 Pacific Fur Company.1690 Panneton (R.) Inc.1690 Papineau Musique Ltée.1691 Placements de Dolbeau Limitée (Les).1691 Placements Belinda Inc.(Les).1691 1776 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 6 avril 1963, Tome 95, No U Lettres patentes Letter* Patent (suite) (continued) Plomberie & Chauffage Cartier Inc.1692 Poly-Glot (1963) Inc.1692 Prestige Construction Ltd.1692 Prestige Construction Ltée.1692 Productions Ciné-Jeunes Inc.(Les).1693 Produits Alba Inc.1693 Prudential Chemical Cor|>oration.1679 Radi-Air Inc.?.1694 Rapid Inc.1694 St-Armand Transport Inc.1694 St.Jean Roofing Inc.1694 St.Gabriel Industries Inc.1686 St.Lawrence Fishing & Hunting Club Inc.1695 Service «les Loisirs Saint-Sixte.1695 Société de Gestion Montcalm Inc.(La).1696 Société de Navigation Touristique Limitée (La).1696 Société «l'Incinération des Cantons de l'Est Inc.1696 Société d'Incinération «lu Bas St-Laurent Inc.1697 Sun Valley Motel Inc.1697 Taverne Legault Inc.1697 Touliatos (Canada) limited.1698 Tourbière Berger Inc.(La).1698 Trafalgar Investments Ltd.1698 Uniformes Québécois Inc.(Les).1699 Verdin Inc.1699 Vitrerie Lalongé Inc.1099 Westmount Draperies Inc.1700 Yamel Inc.1700 Lellxes patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Administration Commerciale Inc.1702 Association Provinciale des Constructeurs d'Habitations du Québec Inc.1701 Bureau d'Ajustement Hébert Ltée.1704 Canadian Insurance Claims Service Corporation.1701 Chalet Barb-Q Incorporated.1701 Chalet Barb-Q Incorporée.1701 Châteauguay Sand Incorporated.1702 Clix Fastener Corporation.1702 Club de Golf Mont Gabriel, Inc.1702 Commercial Administration Inc.1702 Economie Forms & Supports Inc.1703 Edlaff Limited.1703 Foam Specialty Supply Inc.1703 Fonderie St-Hyacinthe Foundry Ltd.1703 Formes & Supports Économiques Inc.(Les).1703 Gala Manufacturing Inc.1703 Germer Holdings Corp.1704 Girartl Inc.1704 Hébert Adjustment Bureau Ltd.1704 Immeubles Nelson Inc.1705 Italian Room Shoe Salon Inc.(The).1705 Juvénat de-la-Salle.1705 Mija Corporation.1705 Mill-Cloak Mfg.Inc.1705 Mont Gabriel Golf Club, Inc.1702 Pieds Légers (1963) Inc.(Les).1706 Placements Marthe Gagnon Ltée.1706 Québec Provincial Home Builders Association Inc.1701 Rol>cl Construction Inc.1706 Rod Service Ltée-Ltd.1706 Service Canadien d'Évaluation de Sinistres Inc.1.1701 Sugermor Holdings Inc.1707 Towne Auto Leasing Inc.1707 Sièges sociaux Head Offices Barone Co.Ltd.1730 203 Cote St.Catherine Road Inc.1736 Couvrette & Provost Ltée.1736 Des Lauriers (Georges) (Montreal) Ltd.1737 Épiceries Frontenac Inc.1737 Épiceries Presto Ltée.1737 Gabriel Management Limited.1738 Imprimerie Stella Limitée.1737 Lucerne Cleaners ( 1963) Limited.1738 Nettoyeurs Lucerne (1963) Limitée.1738 Savoy Holdings Ltd.1736 Télécommunications Richelieu Limitée.1738 Utilités Sanitaires Laurentide Inc.1736 DEMANDES APPLICATIONS à la Législature to Legislature Estate Origène Gol>eille.1738 Pierrefonds.ville - town.1739 Succession Origène Gobeille.1738 EXAMEN - EXAMINATION du Barreau Bar Québec, étude - study.1739 Liquidation Winding Coopérative «lu Bas Perfection Inc.1740 Dante (G.L.) Construction Inc.1740 MINISTÈRES DEPARTMENTAL Affaires municipales Municipal Affaira Ayersville, village (Requête pour déclarer en défaut - Pelitition to declare in default).1740 Magog, canton - township (Publ.)4.1740 Agriculture Agriculture Industrie laitière: Dairy Industry: Ord.5-62-B (Sud «le la province - de Québec - Southern Quebec province).1741 Instruction publique Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Bellerive (Dem.- Appl.).1741 M«>ntheillar«l et Rollet (Dem- Appl.).1742 Petit-Pabos (Dem-Appl.).1742 St-Michel-de-Rougemont, par.(Dem.- Appl.).1742 Val-Julbert (Dem-Appl.).1742 Terres et Forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Girard, canton - township.1742 Lachine, par.1743 Montréal, par.1743 Ste-Foye, par.1743 Ste-Foye, par.1743 St-Vincent-de-Paul, par.1743 Travail Labour Industrie ou métiers de: Industry or Trades of: Coiffeurs pour hommes et dames, Québec (Moi.).1743 Men's and ladies' hairdressers, Quebec (Amend.).1743 NOMINATIONS APPOINTMENTS Divers.\".1744 M isccl laneous.1744 Présidents d'élection.1744 Returning-Officcrs.1744 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 6, 1963, Vol.95, No.U 1777 SOUMISSIONS TENDERS Bedford, ville - town.1745 Cap-de-la-Madeleine, c.s.-8.c.1749 Dollard-des-Ormeaux, ville - town.1751 Greenfield Park, c.s.p.- p.s.c.1747 Labrecque (St-Léon), munie.1748 Québec, cs.c- cs.c.1746 SYNDICATS SYNDICATES Coopératifs Cooperative Caisse d'Établissement de l'U.C.C.de Sherbrooke (La) - (Nom - Name ch.).1752 Caisse Populaire de Saint-Barnabé Nord (La) - (Nom - Name ch.).1752 Professionnel Association des Priuci Professional ux de la Cité de Hull (Const- Inc).1752 VENTES Effets non-réclamés SALES Unclaimed Goods Canadian Pacific Express Company.1753 Licitation Licitation Ferland vs Lehouillier et al.1754 Meilleur ws Charpentier et al.1753 Bankruptcy Act .1754 SHERIFFS Beauharnois Loi de faillite Thibeault, Camille____ SHÉRIFS Beauharnois Prudential Insurance Company of America (The) 99 Slimmon.1755 Central Mortgage and Housing Corporation vs Parrish.1755 Société Centrale d'Hypothèques et de Logement vs Parrish.1755 Bedford Bedford Légaré vs Main ville.1756 Office du Crédit Agricole du Québec (L') MTessier.1756 Quebec Farm Credit Bureau (The) vs Tessier.1756 Chieoutimi Chieoutimi Dallaire (Justin) Ltée vs Bertrand et al.1757 Gaspé Gaspé St-Laurent \u2022 « Therrien.1757 Hull Hull Dent vs Boisvert.1760 Imperial Oil Ltd.vs Aylmer Park Development .1759 MacLachlan vs Labour.1758 Rooke vs Laframboise.1759 Russell 99 Léger.1758 Iberville Iberville Case (J.I.) Credit Corporation 99 Jette.1760 Household Finance Corporation of Canada 98 Lavarière etrir.1761 Joliette Joliette, es.- s.c.va Allen.Joliette .1762 Kamouraska Kamouraaka Oflice du Crédit Agricole du Québec (L') ««Bérubé.1762 Quebec Farm Credit Bureau (The) 99 Bérubé.r 1762 Montmagny Montmagny Lévis Automobile Inc.vs Gamache.1763 Montréal Montreal St-Elzéar, es.-s.c.vs Jardins Montmartre Ltée.1763 Saint-François, es.-s.c.vs Bockler Investment Corp.et al.1764 Sauriol vs Boivin et al.1765 Québec Quebec Lambert (Marcel) Inc.vs Blanchet et al.1765 Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda Crowu Life Insurance Co.(The) vs Gingras.1766 Saguenay Saguenay Interprovincial Building Credits Ltd.vs Desbiens.1766 Témiscamingue Témiscamingue Boulanger vs Pétrin et al.1767 Terrebonne Terrebonne Guay vs Carpenter.1 \"68 Meilleur vs Duncan.1767 Taxes Taxes Rivière-du-Loup, comté - county.1773 Rouyn, cité - city.1772 St-Hubert, ville - town (Correction)- 1771 Sherbrooke, comté - county.1771 St-Maurice, comté - county.1769 L» Ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé raffranohissement en numéraire et 1 envoi comme objet de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second class mail by the Poet Office Department, Ottawa, and for payment of postage in cash. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.