Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 juillet 1964, samedi 4 (no 27)
[" N° 27 3529 Smite officielle de Qnékc QUEBEC OFFICIAL GAZETTE 96> année vol.96 Quebec, samedi 4 juillet 1964 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la Reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2e Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue, la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepte lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la Reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du Ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la Reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la Reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Saturday, July 4, 1961 Rules 1.Address all communications to : The Queen's Printer, Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will be made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for advertising COpy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.In that event, the interested party shall pay upon receipt of his account and before the second insertion: otherwise this insertion will be suspended without further notice and without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.6.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because cf their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiée par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la Reine, ROCH LEFEBVRE.Queen'e Printer \u2014 Québec 8690 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, >, juillet 1964, 96* année.So 97 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents lu ligne agate, POUT clui(|ue version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes pstt pftgei pour let deux versions).Ins< riions subséquentes! 10 cents la ligne agate pour clia-quc ver.-ion.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $1 des km» mots.Exemplaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Alioniu\u2022ment : $10 par année.N.B.\u2014 Les chiffres placés au has des avis ont la signification suivante: Le premier chiffre référé à notre numéro d'ordre; le deuxième à celui de l'édition de la (Uizette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni «le notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro d'ordre.1.' 1 m primeur de la Heine, Boni Lkfkbvkk.Bétel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1902.5177 \u2014 l-52-o Lettres patentes Les Amusements Jacques Filiatrault inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «latc du 15e jour de mai 1004, constituant en corporation : Jacques Trudeau, courtier d'assurance, 6-76, avenue Taschereau, Ste-Thérèsc-en-haut, J.-Gaston Mongeau, comptable, 12, rue des Cèdres, Ste-Thérèse.et Ginette Côté, secrétaire, fille majeure.24.rue Lee«>mptc, Ste-Thérèse.pour les objets suivants: Exercer le commerce qui consiste à fournir de l'amusement au public, sous le nom de « Les Amusements Jacques Filiatrault inc.», avec un capital total de $50.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le Siège social de la compagnie sera 5, boulevard Bra/.eau, Ste-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 15e jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Doivillk.71I0-o 1047-64 Anuhis inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, pur le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 27e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Robert (Jraton, dessinateur et décorateur, 250, Rosedale, Boscmèrc, Roland (Iraton, agent d'immeubles, 6987, avenue Marceau, Pierrefonds, et Georges F.G raton, enquêteur, 3429, rue St-André, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme «lécorateurs, sous le nom «le « Anubis inc.», avec un capital total de Advertising, Rates, Subscriptions, etc.Fiist ins.rtion: 30 «-euts per agate line, f«ir each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents par agate line, for each version.Tabular matter (lists i.f names, figures, etc.) at double rate.Translation: $1.per I'M) words.Single copies: 40 cents each.Slips: |1.80 per dozen.Subscriptions: $10.per year.N.B.- The figures at the bottom of notices have the following meanings The hist figure refers to our document number; the second t«> that of the edition of the Gazette for the first iuser'ion: the third to the number of insertions, and the letter \"«>\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but once are followed only by our document number.Roch Lf.fkbvhe, Queen's Printer.Parliament Buildings.Quebec, May 5.1902.5177 \u2014 l-52-o Letters Patent Lea Amusements Jacques Filiatrault inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Jacques Trudeau, insurance broker 6-76 Taschereau Ave, Stc-Thérèse-en-Haut.J.-Gaston Mongeau, accountant, 12 «les Cèdres St.Ste-Thérèse, and Ginette Coté, secretary, fille majeure, 24 Lccomplc St.Ste-Th'Tèse.for the following purposes: To carry on the business which consists in supplying the public with amusement, under the name of \"Les Amusements Jacques Filiatrault inc.\", with a total capital stock of 850,000, divided into 1,000 common shares of 810 each ami 4.(KM) preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 5 Brazeau Blvd., Ste-Thérèse.judicial district of Terrebonne.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 15th day of May.1964.Raymond Dot villi;, Assistant Secretary of the Province.7110 1047-64 Anubis inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Robert Graton, draughtsman and decorator, 250 Rose-dale, Rosemère, Roland Graton, real estate agent, 5087 Marceau Ave., Pirei refonds, and Georges E.Graton, investigator, 3420 St-André St., Montreal, f«>r the following purposes: To carry on business as decorators, under the name of \"Anubis inc.\", with a total capital stock QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, .lui,, J,, 1964, Vol.96, So.27 140,000, divisé SU 400 ¦étions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de mai 1964.Le Sous-secreluire Je la province, Raymond Doivillk.7110-e 2396-61 of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head Office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of May, 1964.Raymond Don ville, Assistant Secretary of the Province.7110 2396 64 Arnoldi Inc.Avis est donne* qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 36e jour «le mai 1904, constituant en corporation: Louis Freedman, 0008, chemin Nice, Côte-St-Lue, Irwin Aaron Frankel, 635, avenue Algonquin.Mont Royal, tous ration : John T.Barton, professeur, 4860, Bourrât, Montréal, Joseph Beit, évaluateur, 1085, ('hamplain, Duvernay, et V las ta Kabatnid, ménagère, épouse séparée «le biens dudit Joseph Beit, 1085, ('hamplain, Duvernay, p«>ur les objets suivants: Exercer un commerce «le professeurs dans l'art de la coiffure, sous le nom «le « B-B Modem Art Hainlressing School \u2014 Ecole «le coiffure moderne B.B.».avec un capital total de $20,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune.I/c siège social de la compagnie sera 5050, Côtc-des-Neiges, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 21e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor villi:.7110 2022-04 B-B Modern Art llairdrcssing School Ecole de coiffure moderne B.B.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: John T.Barton, teacher, 4S00 Bourret, Montreal, Joseph Beit, estimator, 1085 ('hamplain, Duvernay, and Y las ta Kabatnik, housewife, wife separate as to properly of the said Joseph Beit, 1085 Cham-plain, Duvernay, f«>r the following purposes: To carry on business as hairdrcssing teachers, under the name of \"B-B Modern Art Hairdrcssing School - - Eeok «le coiffure moderne B.B.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 2,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 5950 Côte-dcs-Neiges, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2022-04 Mark Beer Realties Inc.Avis est donné' qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 20e jour de mai 1964, constituant en corporation: Mark Beer, courtier en immeubles, 5175, chemin côte Saint-Luc.( Y>te-Saint-Lue, Martha Bent et Lise Lord, secrétaires, filles majeures, 159, rue Craig ouest, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'iin-meubles, «1wing purposes: To carry on business as experts an«l a«lvisers in business organization and administration, under the name of \"('apex Itée -Capex Lt«l.\", with a total capital stock «>f $10,000, divided into 1,000 common shares of a par value «)f $10 each ami 1,200 preferre«l shares of a par value of $25 each.The head office «>f the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Seeretarv, this 27th day of May, 1904.Raymond Dot;villi:, Assistant Secretarij of the Province.7110 2393-64 Chaussures Karol inc.Karol Shoes Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ijoi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 22e jour de mai 1964, constituant en corporation: Aldy Gagné, manufacturier, 150, Vimy, René Fortin, vendeur, 149, Eymard, et Pierre Légaré, courtier, 540, Malouin, tous trois «le Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes «le chaussures et articles en cuir et leurs accessoires, sous le nom de « Chaussures Karol inc.\u2014 Karol Shoes Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $100 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Sherbrooke, district judiciaire de St-François.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 22e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2255-64 Chaussures Karol inc.Karol Shoes Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of May, 1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Aldy Gagné, manufacturer, 150 Vimy, René Fortin, sal sman, 149 Eyinard, and Pierre Légaré, broker, 540, Ma-loui, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of shoes and leather articles and their accessories, under the name of \"Chaussures Karol inc.\u2014 Karol Shoes Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value of $100 each, ami into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial «listriet of St-Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2255-64 Che/.Milton liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 26e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Arthur Yanofsky, avocat, 2430, Saint-Louis, Montréal, Julius Uriskin, avocat et conseil en loi de la Reine, 134, chemin Finchley, Montréal, Claire Culhane, 2199, Harvard, Montréal, et Grace Blackett, 1451, Closse, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exercer le commerce de restaurateurs, sous le nom de « Chez Milton Itée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.7110 2383-64 Chez Milton Itée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Arthur Yanofsky, advocate, 2430 St-Louis, Montreal, Julius Briskin, advocate and Queen's Counsel, 134 Finchley Road, Montreal, Claire Culhane, 2199 Harvard, Montreal, and Grace Blackett, 1451 Closse, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Chez Milton Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2383-64 3536 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 4 juillet 1964, 90' année.So 27 Club de ski nuiitiquc du Lue Connelly ine.Avis est domé i «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province tie Québec, tics lettres patentes, en tlate du 15e jour de mai 1904, constituant en corj>ora-tion: ft mi le Colas, 25, chemin de Casson, West-mount, Richard David, 8102, rue Viau, St-Léo-nartl.tous deux avocats, et Jean Carouset, stagiaire, 3445.rue St-Urbain, Montréal, pour les objets suivants : Faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et autres commerces semblables, sous le nom de « Club français des bibliophiles inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires tie $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 15e jour de mai 1964.Ia Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2018-64 Club « Les Rigolets » inc.Avis est tlonné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour de mai 1964, constituant en corporation sans capital-actions: Charles Boisvert, représentant, Montréal, Charles-Etienne Thibault, industriel, et Jean-Jacques Fortin, industriel, des deux derniers de Pierreville, pour les objets suivants: Former et diriger un club sportif, sous le nom de « Club « Les Rigolets » inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $30,000.Le siège social de la.corporation sera 19, rue Ally, Pierreville, district judiciaire de Richelieu.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour de mai 1964.Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.7110-o 891-64 Club «h- ski nautique du Lac Connelly inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing tlate the 2ml day of June, 1904, have been issued by the Lieutenant-( îovernor of the Province of Quebec, to Incorporate as a corj>oration without share share capital: Jean St-Pierre, professional engineer, 10375 Clark, Raymond DaOUSt, a«lminislrator, 10403 «le la Roche, both of Montreal, Marcel Lapointe.surveyor, 86 Pontmain, Apt.l, and Normand Lapointe, sold- ercr.5 l'Anse Bleue, the latter two of Luval-des-Rapides.for the following purp«>scs: To form ami direct a sports club, under the name of \"Club tie ski nautique «lu Lac Connelly inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is tt) be limited, is 135,000.The heat! office of the corporation will be at Lac Connelly, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of June.1964.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2174-04 Club français des bibliophiles inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing tlate the 15th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Emile Colas, 25 de Casson Road, Westmount, Richard David, 8102 Viau St., St-Ix'onard, both advocates, and Jean Carouset, probationer, 3445 St-Urbain St., Montreal, for the following purposes: To carry on business as editors, printers, engravers, book-binders ami in other similar trades, under the name of \"Club français des bibliophiles inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of May, 1964.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.7110 2018-64 Club \" Les Rigolets \" inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Charles Boisvert, representative, Montreal, Charles-Etienne Thibault, industrialist, and Jean-Jacques Fortin, industrialist, the latter two of Pierreville, for the following purposes: To form and direct a sports club, under the name of \"Club \"Les Rigolets\" inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $30,000.The head office of the corporation will be at 19 Ally St., Pierreville, judicial district of Richelieu.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of May, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.7110 891-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July J, fMJ, Pet 00.So.3537 A.Cohen Holdings Inc.Avis est donné qu'on vertu «le lu première partie de la Ixii des compagnies «le Québec, il a été juvordé, DAT le lieutenant -gouverneur de lu province «le Québc*»\u2022!.constituant en corporation: Aaron Cohen, agent «l'immcublcs, 20, Springrove Crescent, Out remont.Lillian Lazare, Secrétaire, fille majeure, 9255, place Northcrest, M«)ntréal.et Alan M.Stein, avocat, 5040, avenue Ponaard, Montréal, pour lat Objets suivants: Agir comme une com|>agnie «le placements et de portefeuille, sous le nom «le « A.Cohen Holdings Inc.», avec un capital total «le $40.000, divisé en S.0OO actions onlinaires d'une valeur au pair «le $1 chacune, 22.0(H) actions privilégies catégorie « A » «l'une valeur au pair «le $1 chacune et 10,000 actions privilégiée! catégorie « B », «l'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «\u2022«¦ 22c jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, r.aymohd Douvillk.7110 2325-04 A.Cohen Holdings Inc.Notice is hereby given that Under l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing data the 22nd «lay of May, 1004, have bean lamed by die Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec.incor|>orating: Aar«>n Cohen, realtor, 20 Springrove Crescent, Outremont.Lillian Lazare, secretary, fille majeure.0255 Northcrcst Place, Montreal, and Alan M.Stein.advocate, 5040 Ponaard Avenue.Montréal, for the following purposes: To act as an investment and holding c«»mpany, Under the name of \"A.Cohen Iiolilings Inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 8.000 common shares of the par value of $1 each, 22,000 class \"A\" preferred shares of the par value of 11 each and lO.(MK) class \"B\" preterm! shares of the par value of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22n«l day of May, 1904.raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.7110-o 2325-64 Colomhey constructions Itée Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 22e jour de mai 1064, constituant en corporation: Guy Bélisle, notaire, 48, Grande-Côte, Georges Durocher, secrétaire, 167, rue St-Laurent, et Denise Poirier, secrétaire, fille majeure, 218, rue Dorion, tous trois de St-Eustache, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Colombey constructions Itée ».avec un capital total de'$40,000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Vimont, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour de mai 1964.Le Sous-sccrf taire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2107-64 Colomliey constructions Itée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 22nd «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Guy Bélisle, notary, 48 Grande-Côte, Georges Durocher, secretary, 167 St-Laurent St.ami Denise Poirier, secretary, fille majeure.218 Dorion St., all three of St-Eustache, for the following purposes : To carry on business as builders ami general building contractors, under the name of \"Colombey constructions Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided intriné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnie! de Québec, il a été BCCOrdé, par le licutenang-gnuverneur «le la province de Québec, des lettre! patentes, en date «lu 20e jour de mai 1964, constituant en corporation: J.-Adélard Râtelle, homme d'affaires, Jacqueline Bélisle.ménagère, épouse séparée de biens dudit J.-Adélard Râtelle, et dûment autorise par lui aux fins «les présentes, tous deux «le 152, rue St-Vincent, et Paul Gélinas, avocat, 120 avenue Tour «lu Lac, tous trois de Ste-Agathe-des-Monts, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «l'immeubles et «le construction, sous le nom «le « Domaine La Diligence inc.», avec un capital total de 840,000.divisé en 400 actions ordinaires «le 81(H) chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Aga-the-des-Monts.«listriet judiciaire «le Terrebonne.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 20e jour de mai 1904.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2009-64 Dnval automobile Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 15e jour de mai 1904, constituant en corporation: (iaëtan Duval.Vendeur, 8122, rue St-Gé-rar«l.Montréal, Réal Ilimbeault, vendeur, St-I/Oiiis-dc-Cionxaguc, et Bernard Rochon, représentant, 7365, Shaughnessy, app.1A, St-.Micliel, pour les objets suivants: Exercer le commerce île véhicules automobiles, leurs accessoires et parties et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Duval automobile Itée ».avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires «le SI chacune et en 2,000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à ( 'hâteau-guay, district judiciaire «le Beauharnois.Donné au bureau du secretaire «le la province, ce 15c jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2243-64 bearing date the 29th day f the Province «>f Quebec, incorporating! Leo Rosen tz- veig.1608 Circle Road, Montreal, Stanley Taviss, 7115 Fielding, Montreal.Richard Gottlieb, 2960 Maplewood.Apt.303.Montreal, and William Levitt.5020 St.Kevin.Montreal, all four advocates, for the following purposes: To deal in wearing apparel, under the name of \"Dial Fabrics Ltd.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 3,000 common shares of SI each.27,000 class \"A\" shares of 81 each and 70.000 preferred shares of 81 each.The head office of the «'ompany will be at Montreal, judicial district «>f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 2213-04 Domaine La Diligence inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 20th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: J.-Adélard Râtelle, businessman, Jacqueline Bélisle, housewife, wife separate as to property of the said J.-Adélard Râtelle, ami duly authorized by him for these présents, both of 152 St-Vincent, and Paul Gélinas, advocate, 120 Tour du l^ac Ave., all three of Ste-Agathe-des-Monts, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, umler the name of \"Domaine La Diligence inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head Office «»f the company will be at St-Agathe-«les-Monts, judicial district of Terrebonne.Given at the office f May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110 2009-64 Duval automobile Itée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 15th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gaétan Duval.salesman.S122 St-Gérard St., Montreal, Béai Ilimbeault.salesman, St-Louis-de-Gonza-gue.ami Bernard Rochon, representative, 7365 Shaughnessy, Apt.LA, St-Miehel.for the following purposes: To carry on a business dealing in motor vehicles, their accessories and parts and to operate as garagemen, umler the name of \"Duval automobile Itée\", with a total capital stock of $40,-000, divided into 20,000 common shares of $1 each ami into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at ChAteauguay, judicial district of Beauharnois.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2243-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.IM4.Vol.No.tt 3513 E.T.Ici.( i nt i ii i il il ii al ions Inc.Avis est donné qu'on vertu «le In Manière partie «ie la Loi des f the Province of Quebec, Incorporating: Donald Lyon, sales agent, 1006 Walton Avenue, William Lyon, accountant.220 Argyle Street, ami Bertram D.Lyon, merchant, 164 Wellington Street North, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in office equipment and accessories, umler the name «»f \"K.T.Telecommunications Inc.\", with a total capital stock «»f $40.000, divided into 100 common shares f 1160 each.The head office of the company will be at Sherbrooke, judicial district of St.Francis.Given at the office of the Provincial Secretary, this 15th day of May.1964.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of flic I'mriiice.7110-0 1024-64 Eight Hundred Churchill Boulevard Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-g«>uverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 27e jour de mai 1904, constituant en corporation: Pierre Dcssaulh-s, avocat et conseil en loi de la Reine.812, Upper Lans«lowne, Westmount.John IL Dawson, avocat, 48, chemin Academy, Westmount, Roger B.Dennison, consultant.Hotel Windsor, Montréal, Audrey Agar, secrétaire, célibataire.1221.Crescent.Montréal, et Andrée Provencher, secrétaire, célibataire, 4435.Jeanne-d'Arc.Montréal, pour les objets suivants: Acquérir, diriger et négocier des immeubles.sous le nom de «< Fight Hundred Churchill Boulevard Ltd.\u2022» avec un capital total de S 10,000, divisé en 10,000 actions «irdinaires d'une valeur au pair «le SI chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 27e jour de mai 1964, Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2398-64 Fight Hundred Churchill Boulevard Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letter! patent, bearing «late the 27th day of May.1964* have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Des-saulles.advocate ami Queen's ( Counsel, 812 Upper Lansdowne.Westmount, John II.Dawson, advocate.4.S Aca«lcmy Road.Westmount, Roger B.Dennison.consultant.Windsor Hotel, Montreal, Audrey Agar, secretary, spinster.1221 Crescent.Montreal, ami Andrée Provencher, secretary, spinster.4435 Jeanne-d'Are, Montreal, for the following purposes: To acquire, manage and deal in immoveable property, under the name of \"Fight Hundred Chun-hill Boulevard Lt«l.\", with a total capital stock of SI0,000.divided into 10.000 common shares of a par value of SI each.The heail office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of May, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.7110-O 2398-64 El Mirador construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi îles compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le lu province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 31e jour de «lécembre 1963, constituant en corporation: Maurice Thouin.qunicaillcr.319, Notre-Dame.Repentigny, Louis-Rhéal Tremblay, avocat, 43.rue Ritchot, Repentigny, et Cailles Thouin, avocat.550, rue Notre-Dame, Repentigny, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs et d'entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « El Mirador construction inc.», avec un capital total de SI 00,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le |10 chacune et en 9,000 actions privih'-giées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 319, rue Notre-Dame, Repentigny, «listriet judiciaire «le Joliette.El Mirador construction inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 31st day of December, 1963, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Thouin, hardware merchant.319 Notre-Dame, Repentigny.Louis-Rhéal Tremblay, advocate, 43 Ritchol Street.' Repentigny.and Gilles Thouin, advocate, 550 Notre-Dame Street, Repentigny, for the following purposes: To carry on business as builder! and general building contractors, under the name of \"El Mirador construction inc.*', with a total capital stock of SHK).(MH), divided into 1,000 common shares of $10 each and 9,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company will be at 319 Notre-Dame Street.Repentigny, judicial district «>f Jolictte. 3544 QAZETTË OFFICIELLE DE QUEBEC.I, juillet 1904, OU' année.No 27 Donné au bureau CHI s«m-rétaire de la province, Given at the olliee of the Provincial Secretary, ce Se jour de juin 1064, this Nth «lay of .lune.1904.Le Sons-secrétaire de la province, Raymond Douvillk, Kavmond DOUVILLK.Assistant Secretary of the Province.7 M O-o 5808-63 7110 5906-68 Les Entreprises de l'Ouest iue.Avis est donné qu'en vertu de la premiere partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en «late du 22e jour «le mai 1064, constituant en corporation: Jacques Ceron, 11402, Tardivel, Montréal, André Deslongchantps, 12206, Joseph- Casavant.Montréal, et Serge Morin, 7305, Jean- Bourdon, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire alfaires tannine «\u2022oinpagnic «le placements et de portefeuille (holding), sous le nom «le « Les Fut reprises «le l'Ouest inc.», avec un «-apital total «le $40,000, divisé eu 1,000 actions onlinaires «l'une valeur au pair «le SI chacune et en 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Ia: siège social de la compagnie sera 343a, rue Galt, Verdun, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Doivillk.7I10-o 2329-64 Les Entreprises de FOuest inc.Notice is hereby given that under Fart I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day «»f May, 1904, have been issui-il by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Caron, 11402 Tardivel.Montreal, Amlré Des- longcluunps, 1220s Joseph-Casevant, Montreal, ami Serge Morin.7305 Jean-Bourdon, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under tin' name of \"Les Entreprises «le l'Ouest inc.\", with a total capital Stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of a par value «>f SI each ami into 3,900 preferred shares of a par value of $10 «'a«'h.The head office of the company will be at 343a Gait Street, Verdun, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22n«l day «>f May.1964.Raymond Douvillk, Assisluid Secretary of the Province.7110 2329-64 Entreprises générales de construction du Tcmiscamingue lice Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Quéhef \"Glenelg Lt«l.\", with a total capital stock of $701,000, divided into 1,000 comiiion shares of $1 each ami 7,000 preferre«l shares of $100 each.The head office of the company will be at Suite 500, 355 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 27th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2407-04 Granby Holding Ltd.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Quél>ec, des lettres patentes, en «late du 27e jour de mai 1964, constituant en corporation: J.-C.Fernand Laro.se, homme d'affaires, Aline Delorme, ménagère, épouse contractuel lemcnt sépar«'>e «le biens dudit J.-C.Fernand Larose, tous deux de 11, Mountain, Granby, et Janine Laguë, secrétaire, fille majeure, St-Césaire, pour les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Granby Holding Ltd.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Granby, district judiciaire de Beford.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour «le mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dot;villi:.7110-o 2406-64 Granby Holding Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorj>orating: J.-C.Fernand Larose, businessman.Aline Delorme, housewife, wife contractually separate as to property of the said J.-C.Fernand Larose, both of 11 Mountain, Granby, and Janine Laguë, secretary, fille majeure, St-Césaire, for the following purposes : The industry and business dealing in lumber, under the name of \"Granby Holding Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The heatl office of the company will be at Granby, judicial district of Bedford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2406-64 Hostellerie St-Hilaire inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1964, constituant en corporation: Pierrette Trottier, 610, Lavigucur, Gail Cleary.306.Bayard, Denise Vaclion, 1775, boul.Benoit XV, toutes trois secrétaires, célibataires majeures, Pierre Lesage, avocat, 2012, Hocquart, et Denise Lewis, secrétaire, épouse séparée de biens de Jean-Pierre Gravel, 1410, de Longueuil, tous cinq de Québec, pour les objets suivants: Agir comme compagnie de placements, sous le nom de « Hostellerie St-Hilaire inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 29e jour d'avril 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 1908-64 Hostellerie St-Hilaire inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierrette Trottier, 610 Lavigucur, Gail Cleary, 300 Bayard, Denise Vachon, 1775 Benoit XV, Blvd., all three secretaries, spinsters, Pierre Lesage, advocate, 2012 Hocquart, and Denise Lewis, secretary, wife separate as to property of Jean-Pierre Gravel, 1410 de Longueuil, all five of Quebec, for the following purposes: To operate a business as an investment company, under the name of \"Hostellerie St-Hilaire inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of April, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 1908-64 QUERKC OFFICIAL GAZETTE, July k.196% Vol.96, No.27 3549 Hôtel Maple (Stanstead) limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de ia Loi des compagnies de Quél>ec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 21e jour de mai 1964, constituant en corporation: .L-IL-Hector Simoneau, Lionel Jacques et André P.Charpentier, comptables agréés, de 67, rue King, ouest, Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de « Hôtel Maple (Stanstead) limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Stanstead.district judiciaire de St-François.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21c jour de mai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2097-04 Hôtel Maple (Stanstead) limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 21st day of May, I'.Kit, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: J.-H.-Hector Simoneau, Lionel Jacques and André P.('harpentier, chartered accountant, of 67 King St.West, Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers, under the name of \"Hôtel Maple (Stanstead) limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Stanstead, judicial district of St.Francis.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2097-64 Hôtel Union (Cap-de-la-Madeleine) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20c jour de mai 1964, constituant en corporation: Jacques Tanguay, vendeur, 220, rue St-Pierre, Marcel Roy, homme d'affaires, 378, rue St-Pierrc, et Fernande Tanguay, ménagère, épouse séparée de biens de Denis Morin, 171, rue Fusey, tous trois «le Cap-de-la-Madeleine, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, motels, tavernes, auberges, centres de loisirs, centre sportifs, centres récréatifs et restaurants, sous le nom de « Hôtel Union (Cap-«le-la-Madeleine) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 288, boulevard Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, «listriet judiciaire «le Trois-Rivières.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 20e jour «le mai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2274-64 Hôtel Union (Cap-dc-la-Madeleinc) inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Tanguay, salesman, 220 St-Pierre St., Marcel Roy, businessman, 378 St-Pierre St., and Fernande Tanguay, housewife, wife separate as to property of Denis Morin, 171 Fusey St., all three of Cap-de-la-Madeleine, for the following purposes : To operate hotels, motels, taverns, inns, recreational centers, sports ceulers, and restaurants, under the name of \"Hôtel Union (Cap-de-la-Madeleine) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 288 Ste-Madeleine Blvd., Cap-de-la-Madeleine, judicial district of Trois-Rivières.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2274-64 Les Immeubles Canrobert liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de mai 1964, constituant en corporation: Jacques Boulais, agent «l'affairés, Ste-Cécile-de-Milton, comté de Shefford, Jean-Paul Desroches, industriel, 465, Bourbeau, Granby, Laurier Beaumont, hôtelier, 51, Chapleau, Granby, et Gérard Y.Lemieux, entrepreneur, 439, Bourget, Granby, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom de « Les Immeubles Canrobert Itée », avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à St-Césaire, district judiciaire de St-Hyacinthe.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 20e jour de mai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-e 2278-64 Les Immeubles Canrobert liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Boulais, business agent, Ste-Cécile-de-Milton, county of Shefford, Jean-Paul Desroches, industrialist, 465 Bourbeau, Granby, Laurier Beaumont, hotelier, 51 Chapleau, Granby, and Gérard Y.Lemieux, contractor, 439 Bourget, Granby, for the following purposes: To carry on a business as an investment company, under the name of \"Les Immeubles Canrobert Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at St-Césaire, judicial distrlt of St-Hyacinthe.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2278-64 8860 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, it juillet Î9t'4, 96* aimée.\\o 27 Immeubles la Lumière inc.ImmeublcH La l.utiiiî re inc.La Lumière Bcojttco Inc.ta LmnBHW Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu f May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Queb«*e, incorporating: E/.ra Leithman.Q.c, Fred Kaufman, Sidney Leitliman ami Harvey Yarosky, a«lv«>cates, of 1255 Phillips Square, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Immeubles La Lumière inc.- \u2022 La Lumière Realties Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2205-04 Les Immeubles Leonard Dubé Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Quf May, 1064, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: J.-André M.Dechêne, merchant, Lina Redmond, housewife, wife of the said .L-André M.Dechêne, ami duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 65, 26th Street, St-Ge«>rge.s-Est, ami Jean Langevin, chartered accountant.740, 14th Street, St-f $40.000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares «>f $100 ecah.The head office of the company will be at 054, 1st Avenue, St-Gcorgcs-Est.judicial «listriet of Beauce.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th «lay of May.1064.Raymond Douvillk, Aêtietailt Secrctari/ of the Province.7110 2430-64 Industrial Teletype Electronics Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 21e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Judah Lyon Wolofsky, avocat, 4165, avenue Esplanade, Anne Granofsky, secrétaire, épouse séparée «le biens de Benjamin Neaman, 4825, avenue Mapoewootl, app.3, tous deux «le Montréal, et Martin Aaron Aster, étudiant en droit, 5764, Eldridge, OHe-St-Luc, pour les objets suivants: Faire le commerce «le toutes sortes «l'appareils électroniques et télétypes, sous le nom «le « Indus-trial Teletype Electronics Corp.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera chambre 207, 455, rue Craig, ouest, Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 21e jour «le mai 1964.Iaî Sous-secretaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2332-64 Industrial Teletype Electronics Corp.Notice is hereby given that under Part I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 21st day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-fiovernor of the Province of Quebec, incorporating: Judah Lyon Wolofsky.advocate, 4166 Esplanade Avenue, Anne Granofsky.secretary, wife separate as to propterty of Benjamin Neaman, 4826 Maplewood Avenue, Apt.3, both of Montreal, and Martin Aaron Aster, law-student, 6764 Eldridge, Côte-St-Luc, for the following purposes: To «leal in all kinds of electronic ami teletype equipment, under the name of \"Industrial Teletype Electronics Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Suite 207, 455 Craig Street West, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-0 2332-64 Industrie de la couture de Lamhton inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 26e jour de mai 1964, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat et conseil en loi de la Reine, 1100, Mal bon».Mont-Royal, Bruno Pateras, avocat, 11818, Frigon, Montréal, et Yvan Macerola, avocat, 2090, Place Etienne-Brûlé, Montréal, pour les objets suivants: Industrie de la couture de Lambton inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Malouf, advocate and Queen's Counsel, 1100 Marl-bori, Mount-Royal, Bruno Pateras, advocate, 11818 Frigon.Montreal, and Yvan Macerola, advocate, 2090 Place Etienne-Brûlé, Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, July % t$*4\\ Col.\\o.27 3551 3552 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 juillet 196% 96' année, .Vo 27 Commtrre «le vêtements, sous le nom de « Industrie de la couture de tambton inc.», avec un capital total de $20,000, divise en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 7250, boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au hureau du secrétaire de la province, ce 20e jour de mai 1904.1a Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2384-04 To carry on a business dealing in clothing, under the name of \"Industrie de la couture de Lambton inc.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 20,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 7250 St-Laureut Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2384-64 Institut universel de cours par correspondance inc.Universal Correspondence Schools Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Quebec, il a été accortlé, par le lieutenanr-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 1er jour de juin 1964.constituant en corporation: Claude Guérin.avocat, 32, Les Bouleaux, Laval-sur-le-Lac.Lucienne Maysenhocl-«ler, 3693, St-Hubert, Montréal, et Jeanne Le Sieur.10537, Berri, Montréal, ees deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter des «Voies ou instituts «le COUfl par correspondance, sous le nom «le « Institut universel de cours par correspondance inc.\u2014 Universal Corresponilenee Schools Inc.», avec un capital total de $40,000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de juin 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-0 2427-64 Institut universel de cours par correspondance inc.Universal Correspondence Schools Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «laie the 1st «lay of June, 1964, have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Guérin, advocate, 32 Les Bouleaux, Laval-sur-le-Lac, Lucienne Maysenhoelder, 3693 St-Hubert, Montreal, and Jeanne Le Sieur.10537 Berri, Montreal, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To operate schools or institutes of courses by correspondence, under the name of \"Institut universel de cours par ct»rrespondance inc.\u2014 Universal Correspondence Schools Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of June, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2427-64 Les Investissements Page inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 21e jour de mai 1964, constituant en corporation: Raymond Lette, 27, McNider, Outre-mont, Georges C.Clermont, 455, Beverley, Mont-Royal, et Jean Biron, 7142, boul.Pie X, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements, sous le nom «le « Les Investissements Page inc.».avec un capital total de $3,000,000, divisé en 200 actions ordinaires de $5 chacune et en 299,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 360, rue St-Jacques, ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour de mai 1964.1a Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.71 lO-o 2000-64 Les Investissements Page inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Raymond Lette, 27 McNider, Out remount.Georges C.Clermont, 455 Beverley, Mount Royal, and Jean Biron.7142 Pie X Blvd., Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Investissements Page inc.\".with a total capital stock of $3,000,000, divided into 200 common shares of $5 each and 299,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 360 St.James St.West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2000-04 1TALCA inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de mai 1964, constituant en corpo- ITALCA inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Andréa Mas QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July % 196% Vol.96, No.27 3553 ration: Andréa Mastropietro, 8185, Casgrain, Guiseppe Mastropietro, 8181, ( 'asgruin, tous deux métallurgistes, de Montréal, et Léonce Johin, teneur de livres, 31, des Vétérans, Bouclierville, pour les objets suivants: Faire alfaires comme compagnie de placements, sous le nom de « ITALCA inc.», avec un capital total de $100,000.«livisé en 10,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8980, Clark, Montréal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 22e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doit ville.7110-o 2342-04 tropietro, 8185 (asgrain, Guiseppe Mastropictro, 8181 ('asgrain, both metallurgists, of Montreal, an«l I^éonce Jobin, bookkeeper, 31 des Vétérans, Bouclierville, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"ITALCA inc.\", with a total capital stock |of $100,000, divided into 10,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 8980 Clark, Montreal, judicial «listriet of Montreal.(ïiven at the office of the Provincial Secretary, this 22n«l day of May.1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.7110 2342-04 J.E.L.General Contractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des Compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 25e jour de mai 1964, constituant en corporation: Louis H.Rohrlick, o.k., avocat, 4300, Western, Westmount, Rhona Rothman, secrétaire, fille majeure, 7915, côte St-Luc, Côte-St-Luc, et Benjamin J.Greenberg, avocat, 4211, Grand Boidevard, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de constructeurs généraux et d'entrepreneurs en construction, sous le nom de « J.E.L.General Contractors Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.I>e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de mai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou ville.7110 2370-64 J.E.L.General Contractors Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 25th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Louis H.Rohrlick, q.c, advocate, 4300 Western, West-mount, Rhona Rothman, secretary, spinster of the legal age of majority, 7915 côte St-Luc, Côte-St-Luc, and Benjamin J.Greenberg, a«lvocate, 4211 Grand Blvd., Montreal, for the following purposes : To carry on the business of general builders and building contractors, under the name of \"J.E.L.General Contractors Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each an«l 200 preferre«l shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of May, 1964.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.71 lO-o 2370-64 J.P.Motor Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 21e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Sally Cohen, ménagère, épouse séparée de biens de Sydney Cohen, 1965, rue Norman, St-Laurent, Nathan Friedman, marchand de meubles, et Lottie Friedman, ménagère, épouse séparée de biens dudit Nathan Friedman, ces deux derniers de 5631, Eldridge, Côte-St-Luc, pour les objets suivants : Faire le commerce de machinerie, outils, fournitures et équipements industriels, sous le nom de c J.P.Motor Industries Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1965, rue Norman, St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouviLLE.7110 2305-64 J.P.Motor Industries Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2lst day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Sally Cohen, housewife, wife separate as to property of Sydney Cohen, 1965 Norman Street, St-Laurent, Nathan Friedman, furniture «lealer, and Lottie Friedman, housewife, wife separate as to property of the said Nathan Friedman, the latter two of 5631 Eldridge, Côte-St-Luc, for the following purposes: To deal in machinery, tools and industrial supplies and equipment, under the name of J.P.Motor Industries Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company will be at 1965 Norman Street, St-Laurent, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2305-64 3554 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 4 juillet M4.9t>' année, No 27 Jano Inc.Avis est donné qu'M vertu «le lu première partie «le lu Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, pur le lieutenant-gouverneur de la province «le Quel tec, des lettres patentes, en «lute «lu 1er jour «le juin 1904, «\u2022onstituant en corporation: Mortimer I.('onstuntine.avocat.Mary Kavachol et (îisèle Le Blanc, secrétaires, filles majeures, tous trois de 1255, rue University, Montréal, pour les objet* suivants: Exercer le commerce de meubles, dispositifs et accessoires pour chemins «le fer, nattes, tapis, moquette! et machinerie, sous le nom «le « Jano Inc.», avec un capital total «le §5,000, divisé en 500 actions ordinaires «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera 5751, avenue Verdun, Verdun, «listriet jinliciaire «le Montreal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 1er jour de juin 1064.Le 8oUê-secrétaire de la province, Raymond Douyilub.7110 2471-04 Jano Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 1st «lay of June, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Mortimer J.Constantino, advocate, Mary Ravachol and (îisèle Le Blanc, secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of 1255 University Street, Montreal, for the following purposes: To «leal in furniture, railway fixtures and appliances, mats.rugs, carpets ami machinery, under the name of \"Jano Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 500 common shares of $10 each.The head office of the company will be at 5751 Verdun Avenue, Verdun, judicial «listriet of Montreal.Given at the «>ffi«'c «>f the Provincial Secretary, this 1st day of lune, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2471-04 Jat (196t) limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en «laie du 1er mai 1964, autorisant la fusion de f Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 1902-04 1221/56 Jeff Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a «Hé acconlé, par le lieutenant-g«)uverneur «le la province «le Québec, dee lettres patentes, en date «lu 19e jour «le mai 1904, constituant en corporation: Ja«-k Greenstein.avocat.4S30, rue Fulton, Montréal, Henry Nevard, avocat, 4377, avenue Westmount, Westmount, et Ernest G.Sabloff, notaire, 638, avenue Murray II ill, Westmount.pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie tl'im-meubles et «le construct ion, sous le nom «le « Jeff Realties Inc.».avec un capital total «le $40,000.«livisé en 1.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $10 chacune et 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district jinliciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 19e jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.7110 2247-64 Jeff Realties Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 19th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jack Greenstein, advocate, 4830 Fulton Street, Montreal, Henry Nevard, advocate, 4377 Westmount Avenue, Westmount, anil Ernest G.Sabloff, notary, 038 Murray Hill Avenue, Westmount, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Jeff Realties Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of a par value of $10 each and 3.000 preferred shares of a par value of $10 each.The hea«l office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th .lay of May.1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.7110-o 2347-64 Kara-Van transport liée Kara-Van Transport Ltd.Avis est donne qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 21c jour «le mai 1904, constituant en corporation: lia roll 1 P.Toulch, avocat, 300, rue St-Jacques, ouest, chambre 1515.Montréal, Thelma Stevenson, 195, 6e avenue, St-Eustache, et Karen Sinclair, 3805, boni.Cavendish, app.14, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom «le \"Kara-Van transport Itée \u2014 Kara-Van Transport Lt«l.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 21e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.7110-o 2200-04 Kay Realties (Quebec) Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en Kara-Van transport Itée Kara-Van Transport Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 21st «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Govrvnor of the Province of Quebec, incorporating: Harold P.Toulch, advocate.360 St-Janu*s West, room 1515, Montreal, Thelma Stevenson, 195, 6th Ave., St-Eustache, and Karen Sinclair, 3865 Cavendish Blvd., Apt.14, Montreal, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Kara-Nan transport Itée \u2014 Kara-Van Transport Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each ami into 300 preferred shares of $100 each.The head office t>f the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2206-64 Kay Realties (Quebec) Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the 3556 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, k juillet 190% 90' année.No 27 date du 25e jour de mai 1964, constituant en corporation: Bernard Kogan, 1730, du Collège, Moishe Katz.1735, Ilartenstein, et Théo Anas-tasiadi, S04.Ouimet, tous trois agents d'immeubles, de St-Laurent, potlf les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeubles, sous le nom de c Kay Realties (Quebec) Ltd.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 9,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 870, boul.Décarie, St-Laurent, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour de mai 1964.Lê Sous-secrêtaire de la province, RAYMOND Douvillk.7110-o 2353-64 Province of Quebec, incorporating: Bernard Kogan, 1730 du Collège, Moishe Katz, 1735 Ilartenstein.and Théo Anastasiadi, 804 Ouimet, all three real estate agents, of St-Laurent, for the following purposes: To carry on business as a real estate company, under the name of \"Kay Realties (Quebec) Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 9,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at 870 Décarie Blvd., St-Laurent, judicial «listriet of Montreal.(îiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 25th day of May.1064.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2353-64 Yves Kirouac Itée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la pr«)\\ince de Québec, des lettres patentes, en date «lu 27e jour «le mai 1964, constituant en corporation: Yves Kirouac, grossiste.520, rue Cock-burn, Marguerite Grondin, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens «ludit Yves Kirouac, 520, rue Cockburn, tous deux «le Drum-mondville, et Thomas Kirouac, rentier, 3224, Carré Bouchard, Ste-Foy, pour les objets suivants : Commerce «le vêtements pour hommes, sous le nom de « Yves Kirouac Itée », avec un capital total «le $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 520, rue Cockburn, Drummondville, district judiciaire d'Arthabaska.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 27e jour de mai 1964.1a Sous-secrêtaire de la province, Ray'mohd Douvillk.7110-o 2410-64 Knitbrook Jrs.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 28e jour demai 1964, constituant en corporation: Daniel Kingstone, 4985, avenue Iona, Irving L.Adessky, 5789, avenue Melling, et Brahm L.Campbell, 5500.avenue Snowdon, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants : Exercer le commerce de vêtements pour enfants et adolescents, sous le nom de « Knitbrook Jrs.Inc.», avec un capital total de $5,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et 4,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 28e jour de mai 1964.1a Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2433-64 Yves Kirouac Itée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Yves Kirouac, wholesaler, 520 Cockburn St., Marguerite (¦rondin, housek«*eper, wife contractually separate as to property of the said Yves Kirouac, 520 Cockburn St., both of Drummondville, and Thomas Kirouac, annuitant, 3224 Bouchard Square, Ste-Foy, for the following purposes: To carry on a business dealing in men's clothing, under the name of \"Yves Kirouac Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 520 Cockburn, Drummondville, judicial district of Arthabaska.Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2410-64 Knitbrook Jrs.Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Daniel Kingstone, 4985 Iona Avenue, Irving L.Adessky, 5789 Melling Avenue, and Brahm L.Campbell, 5500 Snowdon Avenue, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To deal in children's and teen agcrs' wearing apparel, under the name of \"Knitbrook Jrs.Inc.\", with a total capital stock of $5,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 4,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2433-64 Langis Labrie inc.Langis Labrie inc.Ayis est donné qu'en vertu de la première Notice is hereby given that under Part I of partie de la Loi des compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.July 4.1964.Vol.96.No.27 3557 été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quéliec, des lettres patentes, en date du 14e jour de mai 19(54, constituant en corporation: Langis Labrie, entrepreneur-électricien, 774, Cherbourg, Ste-Foy, Roger Juneau, comptable, 308, 51e Rue, ouest, St-Rodriguc, et Gaston Michaud, avocat, (5835, Place Boivin, Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens, sous le nom de « Langis l.abne inc.», avec un capital total de $(50,000, divisé en (500 actions ordinaires de $50 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Ste-Foy, «listriet judiciaire de Québec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 14e jour de mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7I10-o 2207-04 bearing date the 14th day of May, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Langis Labrie, contractor-electrician, 774 Cherbourg, Ste-Foy, Roger Juneau, accountant, 3(58, 51st St.West, St-Rodrigue, and (iaston Miehaud, advocate, (5835 Place Boivin, Charleshourg.for the following purposes: To carry on business as electricians, umler the name of '\"Langis Lahrie inc.\", with a total capital stock of $(50,000, divided into m K) common shares of $50 each ami 3(H) preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Ste-Foy, judicial «listriet of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 14th day of May.19(54.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2207-04 Lages Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la provint* «le Québec, des lettres patentes, en «late du 19e jour d'avril 19(54.constituant en corporation: M oses Segal, administrateur, 1745, avenue des Cè«lres, Greta S«-gal, ménagère, épouse contractuellement séparée «le biens «le Lawrence Tarshis, 805.Upper Belmont, tous «leux de Westmount.et Beatrice Démet re.secrétaire, célibataire, 5623, avenue Woodbury.Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de portefeuille, sous le nom de « Images Corp.», avec un capital total de $300,000.divisé en 100 actions ayant droit de vote de $10 chacune, 2,975 actions privilèges catégorie « A » de $100 chacune et 150 actions privilégiées, catégorie jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.7110-o 2362-04 Les Pétroles de Rouville inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th «lay of May, 1964, have l)een issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Marcel Landry, advocate, Beloeil, Francois Payette, advocate, 9029 Gouin Boulevard.West.Saraguay.and Andre Dnboia, law student, 2894 Baldwin St.Montreal, for the following purposes: To deal in fuels, umler the name of \"Les Pétroles «le Rouville inc.\", with a total capital stock «)f 820,000, divided into 500 common shares of $10 each ami 150 preferred shares of $100 each.The head office of the company will he at St-Jean-Baptiste, county of Rouville, judicial «listriet of St-Hyacinthe.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of May.1904.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2362-64 Les Placements Alfa inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a «'té accordé, par le lieuleiiaiil-g«>uvcrncur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de mai 1064, constituant en corporation: Jacques Lamontagne.8452, St-Urbain.Montréal.An«lré Drouin.6790, Louis-Hémon, Montréal, et Basil Danchyshyn, 6612, Des Erables.Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme com pagine «le placements, sous le nom «le « Les Placements Alfa inc.».avec un capital total «le $40.000, divisé en 25 actions or«Iinaires classe « A » «le $10 chacune, 1,975 actions classe « B » de $10 chacune et en 2.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-xccrétaire de la province, Raymond Doivillk.7110-o 2323-04 Les Placements Alfa inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 22n«l «lay of May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jacques Lamontagne.8452 St-lTrbain.Montreal, André Drouin, 6790 Louis-Hémon, Montreal.an«l Basil Danchyshyn, 0612 Des Érables, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Alfa inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 25 common class \"A\" shares of $10 each, 1.975 class \"B\" shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd «lay of May.1904.Raymond Dou villi-:.Assistant Secretary of the Province.7110 2323-04 Les Placements Fleur-de-Lys Itée Fleur de Lys Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour de mai 19(>4, constituant en corporation: Jean Gagné, avocat.10285, rue Jeanne-Mance.Roland Savignac.notaire, Françoise Ri vest, tous deux «le 107, rue St-Jacques, ouest, Réjeanne Morin, 4289, rue St-Zotique, et Normande Gauthier, 2363, rue Chapleau, ces trois dernières secrétaires, filles majeures, tous cinq de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placements et de portefeuille (holding), sous le nom de « Les Placements Fleur-de-Lys Itée \u2014 Fleur Les Placements Fleur-de-Lys Itée Fleur de Lys Investments Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22nd day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Jean Gagné advocate, 10285 Jeannc-Mance St., Roland Savignac.notary, Françoise Ri vest, both of 107 St.James St., west, Réjeanne Morin, 4289 St-Zotique St., and Normande Gauthier, 2363 Chapleau St., the three latter secretaries, filles majeures, all five of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Les Placements Fleur-de-Lys Itée \u2014 Fleur de Lys Invest- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July J,.f0ftg Fat M, No.27 3569 de Lys Investments Ltd.», aver un capital total de $80.000, divisé en 800 actions ordinaires «le $100 chacune.I.i siège sn.ial «h> lu compagnie sera suite 400, 107.rue St-Jacques, ouest, Montréal, «listriet judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du set-retain- «le la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2177-64 Placements Karol inc.Avis est donné «pi'en vertu de la première partie «le la Ix>i ttier, comptable agréé, 230, King, ouest, et Jacques Lagassé, n«>taire, tous trois «le Sherbr«m)ke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le placements et «le portefeuille (holding), sous le nom «le « Placements Karol inc.».avec un capital total «le $40,000, «livisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $100 chacune et en 300 actions privil('»giécs d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Sherbrooke, «listriet judiciaire «le St-Fran«;ois.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2256-64 ments Lt«L\".with a total capital stock of $80,-000, divi«l«*«l into 8(H) common shares of $100 each.The head office of the company will be at suite 400.107 St.lames St.West, Montreal, judicial «listriet of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 22nd «lay of May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2177-04 Placements Karol inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 22n«l day of May.1964, have been issued by the Lieutenant -Governor of the Province of Quebec, incorporating: Pierre Légaré, broker.540 Malouin.André Trot tier.chartere«l accountant, 230 King.West, ami JacqlMS Lagassé.notary, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as an investment ami holding company, under the name of \"Placements Karol inc.\".with a t«>tal capital stock of $40.000 divided into 100 common shares of a par value at par of $100 each and into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The head office «»f the company will be at Sherbrooke, judicial «listriet of St-Franeis.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22n«i «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2256-64 Plomberie f the company will be at 10059 Lille St., Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2249-04 Poitras f St-Hyacinthe.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 1st day «»f June, 19(54.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2445-04 Precision Plastic Mould Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Corapani«\\s Act, letters patent, bearing «late the 20th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Edouard Lapierre, tool-maker, Liliane Kerr, housewife, wife separate as t«> property of the mid Edouard Lapierre, both of 7285, 2nd Ave., St-Michel, and Léon Lapierre.fireman, 12017 Jules-Auclair St., Montreal-North, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of plastic substances, umler the name of \"Precision Plastic Mould Limited\", with a t«>tal capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 3.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal North, judicial «listriet of Montreal.(Jiven at the of lice of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May, 1964.raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 1445-04 l.«- Produits P.II.inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 2Se jour de mai 1904, constituant en corporation: Lise Parent, secrétaire, Paul-Henri Parent, commerçant, et Irène Yézina, ménagère, épouse dudit Paul-Henri Parent, tous trois «le 384.19e Rue.Québec, pour les objets suivants: Commerce «le comestibles, sous le nom «le « Les Produits P.H.inc.».avec un capital total de 140,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 384, 19e Rue.Québec, «listriet judiciaire «le Québec.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 28c jour «le mui 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2423-IÎ4 Les Promotions télévisées (Québec) inc.Television Promotions (Quebec) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 3e jour «l'avril 1904, constituant en corporation: (iérard A.Paris, industriel, 2204, Place McKay, Ste-Foy, Robert Boitcau, industriel, 47, rue «les Érables, ('liâteau-d'Lan.et Thomas W.Brown, avocat, 1105, avenue Belvédère, Québec, pour les objets suivants: l.e- Produits P.II.inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 28th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lise Parent, secretary, Paul-Henri Parent, tra«ler, and Irène Yézina.housewife, wife of the sai«l Paul-Henri Parent, all three of 384, 19th St., Quebec, for the following purpoaes: To deal in food products, under the name of \"Les Produits P.H.inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2.000 common shares of $10 each ami 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 384, 19th St., Quebec, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2423-04 Les Promotions télévisées (Québec) inc.Television Promotions (Quebec) Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 3rd «lay of April, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: (iérard A.Paris, industrialist, 2204 Place McKay, Ste-Foy, Robert Boiteau, industrialist, 47 Des Érables St., Chûteau-d'Eau, and Thomas W.Brown, advocate, 1105 Belvédère Ave., Quebec, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.1004, Vol.00, So.27 3571 ( 'oiumerce.entretien et réparation d'appareils de radio, «le télévision, accessoires électriques, instruments de musique, leurs parties et accessoires, sous le nom «le « Les Promotions télé* visées (Québec) inc.Television Promotions (Quebec) Inc.».avec un capital total «le 840,000, «livisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune et en 8*000 a«'ti«»ns privilégiée! «le $10 chacune.Le liège s«kmuI «le la compagnie sera 388, boni, des Capucins, Québec, district jinliciaire «le Québec.Donné au hureuu «lu secrétaire «le la province, ce 3e jour «l'avril 1004.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douville.7110-o 1511-64 To «leal in, maintain an«l repair radio apparatus, televisions, electrics! access«>rics.musical instruments, their parts au«l accessories, ululer the name of « Les Promotions télévisées (Québec) inc.- Television Promotions (Quebec} Inc.w, with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 each ami 3,000 pre-felted shares of $10 each.The head office of the Company will be at 238 des Capucins Blvd.Quebec, judicial district of Quebec.(iiven at the of lice of the Provincial Secretary, this 3rd day «)f April.1964.Raymond D«ji< villk.Assistant Secretary of the Province.7110 1511-04 Restaurant Central (Rarraute) inc.jT Avis est donné «m'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Quebec, il a f $40,000.divided into 4,000 common shares of $10 each, The hea«l office of the company will be at 974 St-John St., Quebec, judicial «listriet of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2343-64 Restaurant Roma inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 15e jour de mai 1964, constituant en Restaurant Roma inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 15th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Arthur Ca- 3572 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 juillet imi, m« aimée.No 27 corporat ion : Arthur Carey Strafford Stead, avocat, 275, avenue Dorval, Dorval, Roy Calvin Ainaron.avocat, 7.avenue Denton, Dorval, Helen Margaret McLaren, secrétaire, épouse séparée de hiens de Kenneth R.McLaren, 108, avenue Roy, Dorval, et Valerie Anne Rieger, secrétaire, épouse séparée de hiens de Edward L.Rieger, 480, avenue Gallantl.Dorval.pour les objets suivants: Exercer le commerce de restau râleurs, sous le nom de « Restaurant Roma inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégies d'une valeur au pair «le $10 chacune.\\a* siège social «le la compagnie sera à Pointe-Claire, district jinliciaire «le Montréal Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 15e jour «le mai 19(54.Le Sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvillk.7110 1921-04 rey Strafford Stea«l, advocate, 275 Dorval Avenue, Dorval, Roy Calvin Amaron, advocate.7 Denton Avenue, Dorval, Helen Margaret McLaren, secretary, wife separate as to property of Kenneth R.McLami, 108.Roy Avenue, Dorval, ami Valerie Anne Rieger, secretary, wife separate as to property of K«lwar«l L.Rieger, 480 (ialland Avenue, Dorval, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Restaurant Roma inc.\", with a total capital stock of $10.000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferre»! shares «»f a par value of $10 each.The head office of the company will be at Pointe-Claire, judicial «listriet of Montreal.(Jiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 15th day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 1921-04 Richelieu Enterprises Ltd.Avis «'st donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé.par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date «lu 22e jour de mai 19(54, constituant en corporation: Stanley Stcrnthal, administrateur, 7791.chemin Kildare, (Y>te-St-Luc.Leonard Simcoe, avocat, 2787, Benjamin Suite, Montréal, et David Litner, avocat, 4012.Marlowe, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles et de construction, sous le nom de « Richelieu Enterprises Ltd.», avec un capital total de $10,000.«livisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 110 rue Rachel est, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 22e jour de mai 1964.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2298-64 Richelieu Enterprises Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22nd «lay «>f May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, of Quebec, incorporating: Stanley Stcrnthal, executive, 7791 Kildare R«l., Côte-St-Luc, Leonard Simcoe.advocate, 2787 Benjamin Sulte.Montreal, and David Litner, advocate* 4012 Marlowe.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, umler the name of \"Richelieu Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 10,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be at 110 Rachel Street East, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretarv, this 22n«l day of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2298-64 Ross Silk Fabrics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de mai 1964, constituant en corporation: Gregory Charlap, Morris Chaikel-son, tous deux avocats, et Max Slapack, avocat et conseil en loi de la Reine, tous trois de 1374, rue Sherbrooke ouest, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce «le textile et «le tissus en plastique de toutes sortes, sous le nom de « Ross Silk Fabrics Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.I*e siège social «le la compagnie sera 198, lie Avenue, Lachine, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 20e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2276-64 Ross Silk Fabrics Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 20th day of May.19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gregory Charlap, Morris Chaikelson, both advocates, and Max Slapack, advocate and Queen's Counsel, all three of 1374 Sherbrooke Street West, Montreal, for the following purposes: To deal in textile and plastic fabrics of all kinds, under the name of \"Ross Silk Fabrics Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at 198, 11th Avenue, I.adiinc.judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May, 1904.Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.71 lO-o 2276-64 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.190% Vol.90.Xo.37 3573 Gilles Rousseau automobiles Itée Avis aft donné qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies de Québec, il a été accordé, pir le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour d'avril 1904, constituant en corporation: Gilles Rousseau, commerçant, Madeleine Roisseau, ménagère, épouse séparée de biens dudit Gilles Rousseau, tous deux de S17.I le Avenue, et Alhan Rousseau, mécanicien, tous trois de Thetford Mines, pour les objets suivants: Exercer le commerce de véhicules automobiles, leurs parties et accessoires et faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Gilles Rousseau automobiles Itée ».avec un capital total de $40,000, divisé en 250 actions ordinaires «le $100 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Thetford Mines, district judiciaire «le Méguntic.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour d'avril 1904.Le Sous-secrêtaire de la province.Raymond Doivillk.7II0-o 1297-04 Gilles Rousseau automobiles liée Notice is hereby given that umler l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd «lay of April, 1904.have been issue«l by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Rousseau, trader, Madeleine Rousseau, housewife, wife separate as to property of the said Gilles Rousseau, both «>f S17.11th Ave., and Aldan Rousseau, mechanic, all three «>f Tlu'tford Mines, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles, their parts and accessories, and to act as garage-men, umler the name of \"Gilles Rousseau automobiles Réen, with a total capital stock of $40,000.divided into 250 common shares of $100 each ami 150 preferred shares of $100 each.The bead office of the company will be at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22ml day of April.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 1297-04 Salaison Robillard inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a «\u2022té acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 20e jour de mai 1904, constituant en corporation: Sinaï Rohillard, rentier, Noéma Larochellc, ménagère, épouse oontractuellemcnt séparée «le biens dudit Sinaï Robillard, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, et Marcel Robillard, charcutier, tous trois «le Sherbrooke, pour les objets suivants: Commerce «le produits alimentaires.BOUS le nom de « Salaison Robillanl inc.», avec un capital total «le $-10,000, «livisé en 100 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $100 chacune et en 300 actions privilégiées «l'une valeur au pair de $100 chacune.I* siège social «le la compagnie sera à Sherbrooke, district jinliciaire «le St-François.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 28e jour de mai 1064.Le Sous-secrftaire de la province, Raymond Douvillk.71 lO-o 2328-04 Semences Laval inc.Laval Seeds Inc.Avis est «lonné qu'an vertu «le la première partie de la Ix>i des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 28e jour de mai 1904, constituant en corporation: Edouard Le Gresley, grainetier, Robert Le Gresley, étudiant, tous deux de 3467, boul.St-Martin, Chomedey, et Jean-Pierre Le (iresley, technicien en électronique, 2070, Henri-Bourassa, ouest, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce «le graines de semence, plantes, céréales, arbustes, fleurs et pnxluits agricoles de toutes sortes, sous le nom de « Semences Laval inc.\u2014 Laval Seeds Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées tie $100 chacune.Salaison Robillard inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 20th «lay of May.1904.have been named by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Sinaï Robillard.annuitant, Noémn Larochelle, housekeeper, wife contractually separate as t«> property of the sai«l Sinaï Robillanl, ami «luly authorized by him for these presents, and Marcel Robillard, poir-dealer.all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business dealing in food products, under the name of \"Salaison Robillard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of a par value «>f $100 each ami into 300 preferred shares of a par value of $100 each.The hca«l office of the company will be at Sherbrooke, judicial «listriet of St-François.(iiven at the t>ffice of the Provincial Secretary, this 20th day of May, 1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.7110 2328-64 Semences Laval inc.Laval Seeds Inc.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing date the 28th i des compagnies de Québec, il a été accor«lé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de mai 1904.constituant en corporation: Laurent Dubé, avocat.Coaticook, Bertrand Morin.camionneur, et Jean Nil Théroux, camionneur, ces «leux derniers «le Stanhope, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes les parties et accessoires d'automobiles, sous le nom de « Start-X Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Start-X Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 26th day of May.1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Laurent Dubé, atlvocate, Coaticook.Bertrand Morin, trucker, and Jean Nil Théroux, trucker, the two latter of Stanhope, for the following purposes: To carry on business dealing in all parts and accessories for automobiles, under the name of \"Start-X Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.July 4.1904.Vol.90.So.27 3575 l a* siège social (It* la compagnie sera à Coati-cook, district judiciaire «le St-François.Donné au bureau du secrétaire me, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-0 2272-64 Taxis USalle (1964) inc.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a f May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Alphonse Barbeau, advocate, 847 Avenue Dunlop, Outre-mont, Antoine Paré, advocate, 358 Olivier Ave., Westmount, an«l Êvariste Lavoic, accountant, 6991 Briand Ave, Émard, f«>r the following purposes: To opeate a business a taxi stand, umler the name of \"Taxis LaSalle (1961) inc.\", with a capital stock divided into 10.000 common shares without nominal value, 5.000 preferred class \"A\" shares of a nominal value «>f $100 each, 5,000 preferred shares class \"B\" of a nominal value of $10 each ami into 5.000 preferred class \"C\" shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company will be at M mit real, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2169-64 Top Auto Repairs Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date «lu 20e jour de mai 1964, constituant en corporation: M at hi as Kozina, 150, Ashton, St-Laurent, Roland Robillard, 446, Lands«lown, Rosemère, tous «leux avocats, et Lucille Dubois, secrétaire, 6217, Drolet, Montréal, pour les objets suivants: Top Auto Repairs Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th «lay of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Mathias Kozina, 150 Ashton, St-Laurent.Roland Robillard, 446 Landsdown, Rosemère.both lawyers, and Lucille Dubois, secretary, 6217 Drolet, Montreal, for the following purposes: 3570 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, k juillet 1911% .%'\u2022 aimée.No 27 Kxercer un commerce «le garagistes, sous le nom de « Top Auto Repairs Ltd.», avec un capital total de * 10,000.divise en 1.000 actions ordinaires d'une vuleur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacun»'.Le siège sociul «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montrai.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, 00 20e jour «le niai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvilljb.7110 2002-64 To carry ou business as garage-keepers, umler the name of \"Top Auto Repairs Lt«L\", with a total capital stock of $10.000.«livi«le«l into 1,000 common shares of the par value of $10 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head 0006 of the eompuny will be at Montreal, juilicial «listriet of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May, 1904.Raymond Douvillk, Lssistant Secretary of the Province.7110-o 2002-04 Léo Tourigiiy inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compugni«\\s de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 22e jour de mai 1904, constituant en corporation: Léo Tourigny, commerçant, Lise (î.Tourigny, ménagère, épouse dudit Léo Tourigny, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, et Emile Tourigny, vendeur, tous trois «le St-(ïrégoire-le-(îran«l, comté «le Nicolet, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom «le « Léo Tourigny inc.», avec un capital total «le $40.000, «livisé'en 400 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège sociul «le la compagnie sera à St-Grégoirc-lc-Grand.«listriet judiciaire «le Nicolet.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, raymond Douvillk.7110-o 2222-04 I .«'¦«» Tourigny inc.Notice is hereby given that umler Fart i of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22nd «lay of May, 1904, have been Issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Léo Tourigny, trader, Lise G.Tourigny, housewife, wife of the sa n I Léo Tourigny, and (hdv authorized by him for these presents, and Emile Tourigny.salesman, all three «>f St-Grégoire-le-Grand.county of Nicolet, for the following purposes: To carry oh buisncss as grocejf, under the name of \"Lt:«> Tourigny inc.\".with a total capital slock of $10,000, divided into 400 common shares of S100 each.The bead office of the company will be at St-Gn'goire le G rand, judicial «listriet of Nicolet.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of May.1904.Raymond D«>uvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2222-04 Ksdras Tousignant inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 22e jour de mai 1901, constituant en corporation: Banni Tousignant, commerçant.Jeannette Grcffard, ménagère, épouse commune en biens dudit Ksdras Tousignant, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Denis Tousignant, commis, tous trois de 079, rue Réal, La Tuque, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom «le « Ksdras Tousignant inc.», avec un capital total de $-10,000, divisé en 400 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 079, rue Réal, La Tuque, district judiciaire «le Quél>ec.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 2351-04 Ksdras Tousignant inc.Notice is hereby given that under Part i of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22nd «lay of May.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Ksdras Tousignant.tra«ler.Jeannette Greffanl.housewife, wife common as to property of the said Ks«iras Tousignant, ami «luly authorized by him for the purpose of these presents, and Denis Tousignant, clerk, all three of 079, Réal St.La Tuque, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Ksdras Tousignant inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 079 Réal St., La Tuque, judicial district of Quebec.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 2351-64 Universal Brake Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 25e jour de mai 1964, constituant en corporation: Samuel Godinsky, c.r., avocat, 731, Upper Belmont, Montréal, Michael Greenblatt, c.r., avocat, 1745, avenue des Cèdres, Montréal, et Reuben Resin, avocat, 5510, avenue Robinson, Montréal, pour les objets suivants: Universal Brake Corp.Notice is hereby given that under Part i of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel Godinsky, q.c, advocate, 731 Upper Belmont, Montreal, Michael Greenblatt, q.c, advocate, 1745 Cedar Avenue, Montreal, and Reuben Resin, advocate, 5510 Robinson Avenue, Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July % 19(1% Vol.96, \\o.27 3577 Faire le commerce d'un brevet d'invention connexe au sabot de freins, sous le nom «le « Universal Brake Corp.», avec un capital total de $10,000, divisé en 200 uctions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.be siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 25e jour «le mai 1004.Le Sous Secrétaire Je lu province, Raymond Douvillk.7110 2257-01 To deal in a patent pertaining to brake shoes, under the name of \"Universal Brake Corp.\".with a total capital stock of $10.000, divided into 200 common shares of a par value of $10 each and 800 preferred! shares of a par value of $10 each.The head of lice of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of May.1904.Raymond Dou villi:.Assistant Secret uri/ of the I'rorince.7110-0 2257-04 V S Sales Co.Ltd.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la I^oi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de lu province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 22e jour de mai 1904, constituant en corporation: Albert Malouf, cit., 1100, Marlboro Drive, Mont Royal, Bruno Pateras, 11818, Frigon, Vvan Macerola, 2090, Place Etienne-Brûlé, et ('.James Galileo, 0959, Stuart, ces trois derniers de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce de peinture, quincaillerie et spécialités en quincaillerie et nouveautés, sous le nom de « V S Sales Co.Ltd.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 250 actions onlinaires «le $100 chacune et 150 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 1045, rue Dudemaine, Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 22e jour «le mai 1904.Le Sous-sccrHaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2324-04 V S Sales Co.Ltd.Notice is hereby given that umler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 22n«l day of May, 1904, have been issue*! by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert.Malouf, q.c.1100 Marlboro Drive.Mount Royal, Bruno Pateras, 11818 Frigon, Vvan Macerola, 2090 Etienne-Brûlé Place, and C.James Galileo, 0959 Stuart, the latter three of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To «leal in paints, hardware and hardware specialties and novelties, umler the name of \"V S Sales Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 250 common shares of $100 each and 150 preferred shares of $1(K) each.The heatl office of the company will be at 1045 Dudemaine Street, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd «lay of May, 19(54.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 2324-64 Volume Import & Export Inc.|f Avis est donné «pi'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 2(5e jour «le mai 19(54, constituant en corporation: Max Coblents.avocat, 484, rue McGill, .Montreal.Cécile Nadeau, ménagère, célibataire, 4392, avenue Isabella.Montréal, Dorothy Cold-berg, secrétaire, célibataire, 5575, Beaucourt, Montrent, et Ruth Coblents, teneuse de livres, célibataire, 4392, avenue Isabella, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de marchandises vendues généralement dans «les magasins à rayons, sous le nom de « Volume Import & Export Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées «le $1 chacune.Le siège social de la compagnie sera 930, boul.Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 26e jour de mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.7110 2380-04 Volume Import & Export Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Max Co-hlentz.advocate, 484 McGill Street.Montreal, Cécile Nadeau, housekeeper, spinster, 4392 Isabella Avenue, Montreal, Dorothy Goldberg, secretary, spinster, 5575 Beaucourt, Montreal, and Ruth Coblents, bookkeeper, spinster, 4392 Isabella Avenue, Montreal, for the following purposes: To deal in goods usually sold in the departmental stores, umler the name of \"Volume Import & Export Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divuled into 10,000 common shares of $1 each ami 30,000 preferml shares of $1 each.The head office of the company will be at 930 St.Lawrence Blvd., Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7U0-o 2380-64 Voyages Océanair inc.Oceanair Travel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Voyages Océanair inc.Oceanair Travel Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, 3578 QÂZETTM OFFICIELLE DE QUÉBEC, k juillet 196% 96* année.No 27 été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quéliec.des lettres patentes, en date du 27e jour de mai 1004, constituant en corporation: Samuel H.Shriar, Murray H.Spiegel et Maximilieu I'olak, avocats, de 45\"), rue Craig, ouest.Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le commerce d'une agence de voyages, sous le nom de « Voyages Océanair inc.\u2014 Océanair Travel Inc.», aved un capital total de $40,000.divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de mai 1064.Le Sous-tecrétaire de la province.Raymond Douvillk.7110 2405-04 bearing date the 27th day of May.1004, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel H.Shriar.Murray IL Spiegel and Maximilieu Polak, advocates, of 455 Craig Street, West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a travel agency, under the name of \"Voyages Océanair inc.\u2014 Occauair Travel Inc.\", with a total capital stock of s Kl.(KM), divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of May.1004.Raymond Douvillk.Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 2405-04 Voyages Océanair (ouest) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 27e jour de mai 1904.constituant en corporation: Samuel H.Shriar, Murray H.Spiegel et Maximilieu Polak.tous trois avocats, de 455, rue Graig, ouest.Montréal.|>our les objets suivants: Kxercer le commerce d'une agence de voyages, sous le nom de « Voyages Océanair (ouest) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,(XK) actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 27e jour de mai 1904.Le Sou.s-sccrétaire de la province, Raymond Doivillk.7110 2404-04 Voyages Océanair (ouest) inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 27th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel H.Shriar, Murray 1L Spiegel and .Maximilieu Polak, all three advocates, of 455 Craig Street West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a travel agency, under the name of \"Voyages Océanair (ouest) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretarv.this 27th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 2404-04 Ye Olde Pub Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 21e jour demai 1904, constituant en corporation: Claude Leduc, 1097, boul.Graham, Jean Guy, 5400, De Louisbourg, Montréal, et Jean Lefrançois, 191, Maplewood.Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Kxercer un commerce de restaurateurs, sous le nom de « Ve Olde Pub Inc.».avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valuer au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.7110 2268-64 Ye Olde Pub Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Claude Leduc, 1697 Graham Blvd.Mount Royal.Jean Guy, 5100 De Louisbourg.Montreal, and Jean Lcfran-cois, 191 Maplewood.Outremont, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of restaurateurs, under the name of \"Ye Olde Pub Inc.\", with a total capital stock of $10.000.divided into 4.000 common shares of the par value of $10 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.7110-o 2268-64 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Abbott Industries Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Abbott Industries Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 14th day of May, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.100*.Vol.No.27 3579 province «le Qtlé*bec, ni real Chapter.Inc.Notice is hereby given that, umler the provisions «>f the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 21st day of May, 1064, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, to \"National Office Management Association, Montreal Chapter.Inc.\".incorporated umler Part III of the said Quebec Companies Act.by letters patent dated the 14th day of July, 1953.changing Its name to that of \"Administrative Management Society, Montreal Chapter.Inc.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1964.Raymond Dou villi;.Assistant Secretary of the Province.7ll0-«) 14096-63 1221/69 Agence Levis inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 12th day of May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Pro-«luits Chimiques A.C.& Cie Itée \u2014 A.C.Chemicals Co.Ltd.\", incorporated by letters patent 4, à « 1/Association des Daines l'atronncxscs de l'Hôpital Sanatorium St-Joseph incorporée », constituée en vertu «les disposition-, «le la troisième partie de ludite Ixii des compagnies «!«\u2022 Quéliec, par lettres patentes en date «lu 12e jour d'août 1952, changeant son nom en celui «le « L'Associution dflf Dûmes Auxiliuires de l'IIô|iitul St-.Ioseph de Roscmont inc.».Donné au liurcuu du secrétuire de lu province, ce 13e jour «le mai 1004.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 10950-52\u20141223/1 L'Association des Dames Auxiliaires de l'Hôpital St-Joseph de Rosemont inc.Notice is hereby given that, umler the provisions of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 13th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor \"Donohue Brothers, Limited\", incorporated by letters patent «lated the 30th «lay of March, 1920, changing its name to that «>f \"La compagnie Donohue limitée - Donohue Brothers Limited\".(Jiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 27th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 444-20\u20141223/95 La Corporal ion da Lyséc de Silva Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec ( 'ompanies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th «lay of May, 1904.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, to \"L'École nouvelle inc.\", incorporated by letters patent dated the 20th «lay of February, I960 changing its name to that of \"La Corporation da Lysée de Silva\".(iiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 20th .lay of May, 1904.Raymond Dou villi:.Assistant Secretary of the Province.7110 14091-59 -1223/2 Corporation Nationale d'Hypothèque Itée National Mortgage Corporation Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a Corporation Nationale d'Hypothèque Itée National Mortgage Corporation Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, July k, 1944, Vol 96, So.il été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec, des lettres patentes supplémentaires, en date du tie jour de mai 19(54, à la compagnie \"Corporation Nationale d'Hypothèque Itée - National Mortgage Loans Corporation Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 29e jour de janvier 19(54, changeant son nom en celui de «Corporation Nationale d'Hypothèque Itée National Mortgage Corporation Ltd.».Donné au bureau du secrétaire de la province, M be jour de mai 19(54.Le Soux-xecrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 2640-63\u2014 1222/27 letters patent, hot.ring «late the (lib «lay of May.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Corporation Nationale «l'ilypothèipie Itée National Mortgage Loans Corporation Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 29th «lay of January, 1064, changing its name to that, of \"Corporation Nationale d'Hypothè«|uc Itée Nutumnl Mortgage Corporation Ltd.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 6th day of May.1064.Raymond Douville, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 2640-63\u2014 1222 27 Da Pasquali Restaurant, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 10e jour «l'avril 1904, à la compagnie « Da Vito Restaurant Inc.», constituée par lettres patentes en date du 17e jour «le février 1904, changeant son nom en celui de « Da Pasquali Restaurant, Inc.».Donne au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e IOe jour d'avril 1004.Le Soif,.secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.7110 735-04 \u2014 1221/71 Da Pas«|uali Restaurant, Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th day of April.1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, tur d'août 1003, changeant son nom eu celui «le « Destinies & Raymond inc.».Donné au bureau «lu secretaire «le la province, ce 24e jour «l'avril 1904.Le Sous-secrêtaire de la prorince, raymond Douvillk.7110-o 3647-63 \u2014 1223/3 Paul Desmarais Tire Center Co.Avis est donné «m'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late du 20e jour «le mai 1904, a la compagnie « Paul Desmarais Tire Center Co.», étendant ses pouvoirs.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour «le mai 19(54.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 1690-64\u2014 1221/55 Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 24th day of April, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"R.I).Construction inc.\".incoriMirated by letters patent dated the 27th «lay of August.1915.3.changing its name t«> that of \"Deshaies & Raymond inc.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 24th «lay of April, 1064.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110 '3047-03 \u2014 1223/3 Paul Desmarais Tire Center Co.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 20th «lay of May, 19(54, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Paul Désunirais Tire Center Co.\", extending its powers.(Jiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 20th .lay of May, 1904.Raymond Douvillk, Axxistant Secrctari/ of the Province.7110 1099-04- 1221/55 Donohue Brothers, Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date du 26e jour «le mai 19154, à la compagnie « Donohue Brothers, Limited », 1° convertissant ses 900,000 actions «le $3 1/3 en 900,000 actions sans valeur nominale; 2° subdivisant ses 900,000 actions sans valeur nominale Donohue Brothers, Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, t«> \"Donohue Brothers, Limited\", 1.converting its 900,000 shares of $3 1/3 into 900.000 shares without nominal value; 2.subdividing its 900,000 shares without nominal value into 2,700,000 shares without 3584 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.4 juillet t9è% It' muté*» So $7 en 2,7(K).(KK) actions sans valeur nominale; 3° augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 000,000 actions sans valeur nominale; 4° étendant ses pouvoirs.Donné au Imrcau du secrétaire de la province, ce 2(ie jour de mai 1904.Le Sous-sccrctaire de la proriiiee, Raymond Dot villk, 7110-o 444-20\u2014 1222,00 Doyon, Desjeans, Hyde, inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 27e jour d'avril, 1904, à la compagnie « Lionel Doyon Assurances inc.», constituée pur lettres patentes en «late du lie jour «le février 1003.changeant son nom en celui «le « Doyon, Desjcans, Hyde, inc.».Donné au bureau du secrétuirc «le la province, ce 27e jour d'avril 1064.Le Sous-secrêtaire de la proriiiee, Raymond Douvillk.7110-0 670-03\u2014 1222/28 nominal value; 3.increasing its capital stock, the additional capital stock being divided into OOO.(HK) shares without nominal value; 4.extending its powers.(iiven at the ofliee of the Provincial Secretary, this 26th «lay of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 444-20\u2014 1222/96 Doyon, Desjeans, Hyde, inc.Notice is hereby given I hut.umler Purt I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 27th «lay of April, 1964, have bean ianied by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Lionel Doyon Assurances inc.\", incorporate*! by letters patent dated the 11th «lay of February.1963, changing its name Ot that «>f \"Doyon, Desjeans, Hyde, inc.\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 27th day of April.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 670-63\u20141222/28 Entrprises du Nord-Ouest Québécois limitée North-West Quebec Knterprises Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Ixri «les compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 30e jour d'avril 1904, à la compagnie « Lamon limitée », constituée par lettres patentes en «late du 15e jour de mars 1962, changeant son nom en celui de « Entreprises du Nord-Ouest Québécois limitée \u2014 North-West Quebec Knterprises Limited ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 30e jour «l'avril 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou villi:.7110-o 11154-62 \u2014 1222/29 Entreprises du Nord-Ouest Québécois limitée North-West Quebec Enterprises Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of April, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Lamon limitée\", incorporated by letters patent dated the 15th day of March, 1902.changing its name to that of \"Enterprises du Nord-Ouest Québécois limitée \u2014 North-West Quebec Enterprises Limited\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 30th day of April.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 11154-62 \u2014 1222/29 Farr Company Ltd.La Compagnie Farr Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late du lie jour de mai 1904, à la compagnie « Farr Company Manufacturing Lt«l.», constituée par lettres patentes en date du 14e jour de mai 1945, changeant son nom en celui de « Farr Company Ltd.\u2014 La Compagnie Farr Itée ».Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1 le jour «le mai 1964.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110 3479-45\u2014 1221/74 Farr Company Ltd.La Compagnie Farr Itée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of May, 1964, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Fair Company Manufacturing Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of May, 1945, changing its name to that of \"Far Company Ltd.\u2014 La Compagnie Farr Itée\".Given at the office of the Provincial Secretary, this 11th day of May, 1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 3479-45 \u2014 1221/74 W.Gaiptman Inc.W.Gaiptman Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première Notice is hereby given that, umler Part I of partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a the Quebec Companies Act, supplementary été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la letters patent, bearing date the 4th day of May, province de Québec, des lettres patentes supple- 1964, have been issued by the Lieu tenant-mentaires, en «late «lu 4e jour de mai 1964, à la Governor of the Province of Quebec, to \"Beau-compagnie « Beauchamp & frères inc.», cons- champ & frères inc.\", incorporate*! by letters tituée par lettres patentes en «late «lu 26e jour patent «lated the 26th «lay of April, 1963, chang-d'ayril 1963, changeant son nom en celui de ing its name to that of* \"W.Gaiptman Inc.\".« W.Gaiptman Inc.». QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.1964, Vol.96, No.27 3585 Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 4e jour de mai 1904.Le SoiU Secretaire de la province, Raymond Douvillk.7110 1810-03\u2014 1223/4 (iiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of May, 1904.Raymond Douvillk, A ss i.slant Secretary of I he Province.7110-o IS 10-03\u20141223/4 llanicl Transport limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie tie la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 12e jour «le «hk'embre 1903, a la compagnie « Hamel Transj)ort limitée », 1° réduisant son capital de $75,000 à $20,200, le capital-actions annulé étant «livisé en 488 actions ordinaires «le $100 chacune; 2° convertissant ses 112 actions onlinaires «le $100 chacune en 112 actions priviléfriées de $100 chacune; 3° sub«livisant ses 150 actions onlinaires «le $100 «\u2022haeune en 15,000 actions onlinaires «le $1 chacune; 4° augmentant son capital de $20,200 à $590,000, le capital-actions additionnel étant «livisé en 5.G38 actions privilégiées «le $100 chacune.Donné au bureau «lu sel 1228/6 Luurentian Dolomite .Mining Limited No Personal I iahility) Les Mines Laiirentiemies de Dolomie limite»-(Libre de res|m>nsuhilitc personnelle) Avis est donné qu'en vertu «les dispositions de lu Loi «les compagnie! minières et de lu première partie «le lu Loi des compagnies «!«¦ Quebec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur de lu province » (Libre «le responsabilité personnelle), augmentant son capital de $150.000 A $100,000.le cupit ai-actions additionnel étant divisé en 260,000 actions catégorie « A » d'une valeur au pair «le $1 chacune.Donne au bureau du secrétaire «le la province, ce 20e jour de mai 1964.Le Sous secrétaire de la province, Raymond Doi VILLE.7110 2:501-b:! 1222/123 (iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May.190».Raymond Doivillk, Assistant Secretary of the Province.7110 001-04 - 1223/5 Laurent ian Dolomite Mining Limited (No Personal Liability) Les Mines Laurentiennes de Dolomie limitée (Libre de responsabilité personnelle) Notice is hereby given thut.under the provisions of the Quebec Mining Companies Act and of Purt 1 «>f the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing tlate the 20th «lay of Muy, 1001.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Luurcntiun Dolomite Mining Limited\" (No Personal Liability) \"Les Mines Laurentiennes tie Dolomie limitée\" (Libre «le responsabilité personnel! ), increasing ils capital from $150.000 to 1400,000, the additional capital stock being divided into 250.000 class \"A\" shares of the par value of $1 each.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of May.1004.Raymond Doivillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 2301-63 1222 123 Local Transport Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le lu première purtie «le lu Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu lie jour «le mai 1964, à la compagnie « Local Transport & Excavating Company Limite»! », constituée pur lettres patentes en f Quebec, to \"Locul Transport & Excavating Company Limited*', incorporated by letters patent dated the 31st day of January, 1947, \u2022\u2022hanging its name to thut of 'Local Transport Ltd.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 14th «lay of May.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o \" 1522-47\u2014 1223/0 Lomi Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies tie Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 25e jour de mai 1904, à la compagnie « Lonn Overall & Pants Mfg.Co.».constituée par lettres patentes en «late du 24e jour de mars 1955, 1° changeant son nom en celui de « Lonn Imlust ries Ltd.»; 2° «'tendant ses pouvoirs; 3° augmentant son capital «le $290,000 à $305,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 150 actions onlinaires «le $100 chacune.Donné uu bureau du secrétaire «le la province, ce 25e jour de mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 10(537-55\u2014 1222/37 Lonn Industries Ltd.Notice is hereby given that, under Part I «>f the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 25th «lay of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Lonn Overall & Pants Mfg.Co.\", incorporated by letters patent dated the 24th «lay of March, 1955, 1.changing its name to that of \"Lonn Industries Ltd.\"; 2.extending its powers; 3.increasing its capital from 0200,000 to $.305,000, the athlitional capital stock being divided into 150 common shares of $100 each.(Jiven at the offi«?e of the Provincial Secretary, this 25th «lay of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110-o 10637-56 \u2014 1222/37 Man\\ an Trading Corp.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la Man van Trading Corp.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st «lay of May, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.Vol.9ti, So.27 3587 province de Quebec, des lettres patentes supplémentaires, en date «lu 21e jour de mai 1904, à la compagnie « M any au Trading Corp.», étendant ses pouvoirs.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 21e jour de mai 190 t.Ij\u20ac Sous-secrêtaire Je la province, Raymond Douvillk.7110 15578-59 - 1222/88 Mid-Town Klectrie Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, de* lettres patentes supplémentaires, en «late du 20e jour d'avril 1004.à la compagnie « Mhl Town T.V.& Appliance Centre Ltd.».constituée par lettres patente! en «late du 10e jour de février 1951.changeant son nom en celui de « Mi«l-T«jwn Electric Inc.».Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 20e jour d'avril 1964.Le Sous-secrêtaire tic la province, Raymond DOU ville.7110-o 10326-54 1221,85 Miller Displays Ltd.Les Étalages Miller Itée Avis est donné* qu'en vertu «le lu première partie «le lu Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 15e jour d'avril 1904, à lu compugnie « Miller ('«munercial Displays Ltd.», Constituée par let tirs patentes en «late du 2e jour de mai 1950, changeant son nom en celui «le «Miller Displays Ltd.\u2014Les Étalages Miller lt«:e ».Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 15e jour «l'avril 1904.Le Sous-secrêtaire Je la province, Raymond Doivillk.7110 3883-50 1221 86 1904, have been issued b.v the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Manyan Tra«ling Corp.\", exteiuling its powers.(iiven at.the othYe «>f the Provincial Se«:retary, this 21st day of May, 1064.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 15578-59 1222/38 Mid-Town Electric Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 20th «lay of April.1064, have been issued by the Liutcnanl-(Jovernor of the Province of Quebec, to \"Mid-Town T.V.& Appliance Centre Ltd/*, incorporated by letters patent dated the 191 h day of February, 1954, changing its name t«> that of \"Mid-Town Klectric Inc.\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of April.1004.Raymond Douvillk, Assistant Sccretani of the Province 7110-o 10325-54 - 1221/85 Miller Displays Ltd.Les Étalages Miller liée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day «>f April, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Miller ('«munercial Displays Ltd.**, incorporated by letters patent dated the 2nd day of May, 1050, changing its name to that of \"Miller Displays Ltd.\u2014 Les Étalages Miller lt«:«'\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 15th «lay of April.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110-o 3883-50\u2014 1221,80 Pierce Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en date «lu 15e jour «le mai 1904, à la compagnie « Pierce Corporation », augmentant son capital, le capital-actions additionnel étant divisé en 1.000.000 d'actions privilégiées de 81 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 15e jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Itou ville.7110 1304-31 \u2014 1222/39 Pierce Corporation Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «lute the 15th day of Muy.1964, have Im'en issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, t«> \"Pierce Corporation\", increasing its capital, the additional cupitul stock being divided into 1,000,000 preferred shares of Si each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 15th «lay «>f May.1964.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Pmrince.7110-o 1304-31\u2014 1222/39 Ives Presses Mont Royal limitée Mount Royal Press Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes supplémentaires, en date du 5c jour de mai 1904, à la compagnie « Mount Royal Press, Limited », constituer par lettres patentes en «late du 20e jour de février 1923, changeant son nom en celui de « Les Presses Mont Royal limité»' \u2014 Mount Royal Press Limited ».Les Presses Mont Royal limitée Mount Royal Press Limited Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 5th day of May, 1904, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Mount Royal Press, Limited**, incorporated by letters patent «late«l the 20th «lay of February, 1923, changing its name ot that of \"Les Presses Mont Royal limitée \u2014 Mount Royal Press Limited\". 3588 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 4 juillet 1904, 90' année.So 27 Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, «\u2022e 5c jour «le mai 19(i4.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110 195-23 - 1222/44 Produits Allia inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettre* patentes supplé-mcntaires, en date du 1er jour «le mai 1904, à la compagnie « Produits Alba inc.», augmentant son capital «le $200,000 à $300,000, le capital-actions additionnel étant «livisé en 10,000 actions onlinaires de $10 chacune, Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 1er jour «le mai 1904.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.7110-o 408-03 \u2014 1222/46 Given at the Office of the Provincial Secretary, tins 5th tlay of May, 1904.Raymond Douvillk, Assistant Secrctari/ of the Province.7110 o \" 195-23\u2014 1222/44 Produits Alba inc.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 1st f the Province of Quebec, to \"Pierre Tardif inc.\", increasing its capital stock from $50,000 to $150,000, the a«l«litional capital stock being divided into 10,000 preferre«l shares of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 10810-55\u2014 1222/48 Three Rivers Grain and Elevator Company Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of May, 1964, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Three Rivers Grain and Elevator Company Limited\", reducing its capital, the capital stock annulled being divided into 30,000 preferred shares of $100 each.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 13th day of May, 1964.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.7U0-o 2673-35\u2014 1222/50 8000 GAZETTE OFFICIELLE DE QVEllEC, 4 juillet 196% 96* année.So 27 Ton» less Corporal ion (Canada) Avis pal donne qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies de Quéliec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettrée patentes supplémentaires, en date du Ile jour de mai 1904, à la compagnie « Home Steel Products Ltd.», constituée par lettres patentas en «late «lu 80a jour «l'août 1950, changeant son nom en celui de « Toastes* Corporation (Canada) ».Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce I le jour «le mai 1904.Le Sous-.secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 6184-50 1221/94 I,o Tour du S t-Laurent Cycliste incorporée lie Tour du St-Lsuxrent Cycliste Incorporated Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les «-ompagines «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplé-mentair«'s, en date du 27e jour de septembre 1903, à la compagnie rutcmpagnies de Québec, il a été acconlé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 1er jour de mai 19(>4.à la compagnie « The Tutoring Academy Inc.».constituée par lettres patentes en date du lie jour «le février 1904.changeant son nom en celui «le « The Tutoring Academy Inc.\u2014 L'Académie d'Études Supplémentaires inc.».Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 1er jour «le mai 1904.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.7110 036-04\u2014 1222/51 Toastess Corporal ion 'Canada : Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the llth day of .May, 1964, have la-en issued by the Lieutenant- Governor of the Province of Quebec, t«> \"Home Steel Products Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 30th day «»f August, 1950, changing its name to that of \"Toast«\\ss Corporation (( 'ana«la)\".(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this llth day «»f May.1904.Raymond Douvillk.Assistant Secretary if the I'rorince.7I10-o 6184-60 1221/94 I^e Tour du St-Laurcnt Cycliste im-orporée Le 'lour du St-Ijuircnt Cycliste Incorporated Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 27th «lay of September.1963.have been issued by the Lieutenant Governor of the Province of Quebec, to \"Le Tour du St-Laurent Cycliste incorporée \u2014 Le Tour «In St-Laurcnt Cycliste Incorporate*!\", increasing its capital stock from $40.000 to $100.000, the additional share capital being divided into ooo common shares of $100 each.(iiven at tin' office of the Provincial Secretary, this 3rd «lay of .June.1904.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.7110 12001-60 - 1221/04 The Tutoring Academy Inc.L'Académie «l'Êtudes Supplémentaires inc.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act.supplementary letters patent, bearing «late the 1st day of May.1964.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"The Tutoring Academy Inc.\", incorporated by letters patent dated the llth day of February, 1964, changing its name to that of \"The Tutoring Academy Inc.-L'Académie «l'Étiules Supplémentaires inc.\".(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of May.1964.Raymond Douvillk, Assistant Secretary if the Province.7110-o 630-64 1222/51 Arrêtés en Conseil Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1246 Section « A » Québec, 25 juin 1964.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au décret relatif aux métiers «le barbier, coiffeur et coiffeuse dans le comté de Roberval.attendu que, conformément aux dispositions de la Ix>i de la convention collective (Statuts refondus «le Québec, 1941, chapitre 163 et amen- Order in Council Executive Council Chamber Number 1246 Section \"A\" Quebec, June 25, 1964.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment of the «lecree relating to the barbering ami hairdressing trades in the electoral «listriet of Roberval.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Act (Revised Statutes of Quebec, 1941, chapter 103 and amendments), the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 4.m*.Vol.96, No, 97 3591 dements), les parties eontnu-tuntes à la convention Collective de travail relative aux metiers de l>arl»ier, eoitleur et e.iifl'ciise dans le comté de Rohcrvnl.rendue obligatoire par le décret numéro 1288 du 15 novembre 1951 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la dérision du lieutenant -gouverneur en conseil une modification audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans lu Gazette officielle de Québec, édition du 9 mai 1064; Attende Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation «le la modification proposée; ii.bot ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 1283, soit modifie* comme suit: 1° L'alinéa 2 du paragraphe « a » de l'article IV est remplacé par le suivant: « 2° PoW lêi coiffeurs et coiffeuses: Lundi: I p.m.à fi p.m.: Mardi, mercredi et jeudi: 8 a.m.à fi p.m.; Vendredi: de 8 a.m.à 9 p.m.; Samedi: 7 a.m.à midi.La veille de Noël et du Premier jour de l'An: de 8 a.m.à fi p.m.Cependant, le samedi seulement, trois (3) heures sont allouées pour terminer le travail requis par les clientes entrées avant midi.» Jacques Pkkmont, 7115-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.\\rrété en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1246 Section « li » Québec, le 25 juin 1964.Présent: Ia: licutenunt-gouverneur en conseil.Concernant une modification au décret relatif aux Coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drum-mond, Richelieu et Shefford.Attkndu yi'k.conformément aux dispositions de la Ix>i de la convention collective (Statuts refondus de Québec.1941, chapitre 163 et amendements), les parties contractantes à la convention collective de travail relative aux coiffeurs pour hommes et coiffeurs pour dames dans les districts électoraux de Drummond, Richelieu et Shefford, rendue obligatoire par le décret numéro 2468 du 27 décembre 1961.ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet «le soumettre à l'appréciation et à la décision «lu lieutenant-gouverneur en conseil une modification ainlit décret; Attendu qui ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition «lu 9 mai 1964; Attbnou Qu'aucune objection n'a été formulée «\u2022ontre l'approbation «le la modification proposée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2468, soit modifié comme suit: L'exception 1° pour la zone I apparaissant au paragraphe « a » «le l'article 121 est remplacée par la suivante: «x Exceptions : 10 À Sorel.Tracy et St-Joseph de Sorel et le territoire compris tlans un rayon de contracting parties to the Collective labour agreement relating to the barberiug ami hair-dressing trades in the county of Roberval, rendered obligatory by tin- decree number 1283 of November 15, 1061, and amendments, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of (In- Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said decree; Win-: i«k a s the petition has bean published in the Quebec Official Gazette, issue of Mav 9, 1964; Whbbeah no objection has be«mi made against the approval of the proposed amendment; It isoudainkd.therefore, upon the recommen* dation «>f the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 1283, be amended as follows: 1.Sub-paragraph 2 of paragraph \"«\" of article IV is replaced by the following: \"2.Hairdressers (male and female): Monday: 1 :(m) p.m.to 6:00 p.m.; Tuesday.Wednesday ami Thursdav: 8:00 a.m.to 6:00 p.m.; Friday: 8:00 a.m.to 9:00 p.m.; Saturday: 7:00 a.m.to 12:00 (noon); Christmas Eve and N«'w War's Eve: S:00 a.m.to 6:00 p.m.However, three (3) hours are allowed on Saturday to complete the services mpiircd by the customers who entered the parlour before 12:00 (noon)\".Jacques Pkkmont, 7116-0 Associate Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1240 Section \"/>\" Quebec, June 25.1964.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the decree relating to the barberiug and hainlressing trades in the electoral districts of Drummond, Richelieu and Shefford, Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Labour Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941.chapter 163 an«l amendments), the contracting paraes to the collective labour agreement relating to the barberiug and hainlressing trades in the electoral districts of Drummond.Richelieu and Shefford, remlered obligatory by decree number 2468 of December 27.1961, have petitioned the Minister «»f Labour to submit to the consideration ami decision of the Lieutenant-Governor in Council an amendment to the said decree; whereas the petition has been published in the Quebec Official Gazette, issue of May 9, 1964; whereas no objection has been raised against the approval of the proposed amendment; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 2468, be amended as follows: Exception 1.for zone I mentioned in paragraph \"a\" of article 121 is replaced by the following: \"Exceptions: 1.In Sorel.Tracy ami St.Joseph de Sorcl an«l the territory comprised in a radius 3592 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 4 juillet 19*% 96' année.No 27 cinq (5) milles «le leurs limites, les heures régulières île travail sont les suivantes: Mardi, mercredi, jeudi: 8 a.m.à 6.30 p.m.Vendredi: S a.m.a 9.30 p.m.Samedi: 8 a.m.à 5 p.m.» Jacquks Pkkmont, 7115-o Greffier Adjoint du Conseil Exécutif.of five (5) miles from their limits, the standard hours shall he as follows: Tuesday, Wednesday, Thursday : 8:00 a.m.to 6:30 p.m.Friday: 8:00 a.m.to 9:30 p.m.Saturday: 8:00 a.m.to 5:00 p.m.\" Jacquks Pkkmont, 7115-o Associate Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 12-16 Section « D » Québec, 25 juin 1964.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Conckknant des modifications au décret relatif à l'industrie de l'automobile dans la région de Drummond.Attkndu que, conformément aux dispositions de la Loi de la convention collective (Statuts refondus de Québec 1941, chapitre 168 et amendements), les parties contrat-tantes à la convention collective de travail relative à l'industrie de l'automobile dans le district électoral «h* Drummond, rendue obligatoire par le décret numéro 102 du 31 janvier 1957 et amendements, ont présenté au Ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-Gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la G.izctte officielle de Québec, édition du 11 janvier 1064; Attkndu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Il kst ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail: QUE ledit décret, numéro 102, soit modifié comme suit : 1° L'article IV est remplacé par le suivant: « IV.Taux minima de salaire: Pour les fins du présent article, la juridiction territoriale est divisée en deux (2) zones et les taux minima suivants doivent être payés aux salariés ci-après mentionne-, : Zone 1: La cité de Drummondville et un rayon de trois (3) milles de ses limites.Zone II: Le reste de la juridiction territoriale.Order in Council Executive Council Chamber Number 1246 Section \"D\" Quebec, June 25, 1964.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Conckknino amendments to the decree relating to the automobile industry in the electoral district of Drummond.Whkkkas, pursuant to the provisions of the Collective Labour Agreement Act (Revised Statutes of Quebec 1941, chapter 163 and amendments), the contracting parties to the collective labour agreement relating to the automobile industry in the electoral district of Drummond, rendered obligatory by decree number 102 of January 31, 1957 and amendments, have petitioned the Minister of Labour to submit to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council, some amendments to the said decree; Whkkkas the petition has I ecu published in the Quebec Official Gazette, issue of January 11, 1064; Whkkkas no objections has been raised against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore.Upon the recommendation of the Honourable the Minister of Labour: That the said decree, number 102, be amended as follows: 1.Article IV is replaced by the following: \"IV.Minimum rates of wages: For the purposes of the present article, the territorial jurisdiction is divided into two (2) zones and the following minimum rates shall be paid to the employees hereafter mentioned; Zone I: The city of Drummondville and a radius of three (3) miles within its limits.Zone II: The remainder of the territorial jurisdiction.L Dans les garages -In garages Zone I Taux horaires \u2014 Hourly rates Métiers \u2014 Trades: 1er oct.1er act.Oct.1, Oct.1, Mécanicien: automobile et tracteur \u2014 Automobile and tractor 1964 1965 mechanic: Première classe \u2014 Fifst class.$1.80 $1.90 $1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1.60 1.70 1.75 Troisième classe \u2014 Third class.1.45 1.55 1.60 Machiniste-ajusteur \u2014 Machinist-fitter: Première classe \u2014 First class.1.80 1.90 1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1 60 1.70 1.75 Troisième classe \u2014 Third class.1.45 1.55 1.60 Débosscur-peintre \u2014 Bodyworker-painter : Première classe \u2014 First class.1.80 1.90 1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1.60 1.70 1.75 Troisième classe \u2014 Third class.1.40 1.50 1.55 Électricien-automobile \u2014 Electrician (automobile) : Première classe \u2014 First class.1.80 1.90 1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1.60 1.70 1.75 Troisième classe \u2014 Third class.1.45 1 55 1.60 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July % 196% Vol.96, Xo.27 3593 Zone I Taux horaire» \u2014 Hourly rates Metiers \u2014 Trades: 1er oct.1er oet.Get.1, Oct.1, Soudeur: automobile, eamion, tracteur Welder: automobile, lU6/t 1065 truck, tractor: Première classe \u2014 First class.$1.80 $1 90 $1 95 Deuxième classe \u2014 Second class.1 60 1.70 1.75 Troisième criasse Third class.I .45 1 55 I 60 Alignement et balancement de roues Wheel aligning and balancing: Première classe First class.1.80 1 90 1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1.60 1.70 1.75 Troisième classe \u2014 Third class.1.45 1 55 I 60 Redresseur de châssis, alignement et suspension de l'automobile \u2014¦ Frame straightener and alignement and automobile suspension: Homme en charge - Head worker.2.00 2.10 2 15 Première classe - First class.1.80 1.90 1.95 Deuxième classe \u2014 Second class.1.60 1.70 1.75 Troisième classe Third class.1.45 1.55 1.60 Apprentis (compagnons) - Apprentices (journeymen) : Première année First year.0.95 1.05 1.10 Deuxième année \u2014 Second year.1.10 1.20 ] .25 Troisième année Third year.1.25 1.35 1.40 Hommes d'ouvrage général \u2014 General hands: Première année \u2014 First year.0.85 0.95 1.00 Deuxième année \u2014 Second year.1.00 1.10 1.15 Troisième année \u2014 Third year.1.15 1.36 1.30 Spécialité \u2014 Specialty : Graisseur spécialisé \u2014 Specialized greaser.1.50 1 AM) 1.65 Vulcanisateur \u2014 Vulcanizer.1.55 1.65 1.70 Préposés aux pièces \u2014 Parts department employee: Par semaine - Per week Premier semestre \u2014 First six months.$32.50 $37.50 $40.00 Deuxième semestre - Second six months.37.50 42.50 45.00 Deuxième année \u2014 Second year.42.50 47.50 50.00 Troisième année \u2014 Third year.47.50 53.50 55.00 Après la quatrième année \u2014 After fourth year.65.00 70.00 72.50 Homme en charge aux pièces \u2014 Head clerk (parts department) 75 00 80.00 82.50 (iardien: (Préposé à la surveillance et à l'entretien) \u2014 Watchman (watching and maintenance).47.50 52.50 55.00 Assistant-gérant «le service \u2014 Service manager assistant.52.50 57.50 60.00 2.Dans les stations de service et débits d'essence In service stations and gasoline stations Zone I Taux horaires \u2014 Hourly rates Métiers \u2014 Trades: 1er oct.1er oct.Oct.1, Oct.1, 196/, 1965 Homme de service \u2014 Service man: Après trois ans \u2014 After three years.$1.30 $ 1.40 $1.45 Apprentis \u2014 Apprentice: Première année \u2014 First year.0.80 0.90 0.95 Deuxième année \u2014 Second year.0.95 1.05 1.10 Troisième année \u2014 Third year.1.05 1.15 1.20 Moins de 18 ans \u2014 Under 18 years of age: Première année \u2014 First year.0.70 0 80 0.85 Deuxième année \u2014 Second year.0.75 0.85 0 90 3.Dans les terrains de démolition \u2014 In scrap yards Homme d'ouvrage général \u2014 General hand.1.35 1.45 1.50 Apprentis \u2014 Apprentices : Première année \u2014 First year.1.05 1.15 1.20 Deuxième année \u2014 Second year.1.15 1.25 1.30 Troisième année \u2014 Third year.1.35 1.45 1.50 Zone II: Les taux minima ci-haut mentionnés sont réduits de $0.10 l'heure.» 2° L'article V est remplacé par le suivant: « V.Jours de fêtes chômés et payés: a) Les jours suivants sont chômés et payés : Le Premier jour de l'An, le 2 janvier, la Saint-Jean-Baptist e.la Confédération, la fête du Travail et Noël.6) Tout salarié requis de travailler le dimanche ou l'un de ces jours fériés doit être rémunéré À temps double.* Zone II: The aliove minimum rates shall be reduce
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.