Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 avril 1965, samedi 3 (no 14)
[" 97\" année vol.97 N° 14 2075 k/Mif officielle f}wkc QUEBEC OFFICIAL GAZETTE QuëbeCt samedi .'l avril 1965 Règlements 1' ^drawer toute correspondance à: ITnipri-iii.in- de la reine, Hôtel du Gouvernement.Québec.2° Fournir le texte de l'annonce daais les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.8\" Indiquer le nombre d'insertions.1' Payer comptant et avant publication le (\u2022dût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas.l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6* Tout paiement doit être fait par chèque OU mandat à l'ordre du Ministre des Finances.73 La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonce», expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8\" Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la \u2022seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Oiiehec.Saturday.April 3, 1965 Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer.Parliament Buildings.Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy is supplied in one language only, the translation will lie made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for advertising copy according to the rates set forth below, exception when the copy is to be published several times.In that event, the interested party shall pay upon receipt of his account and before the second insertion: otherwise this insertion will he suspended without further notice and without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.6.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second Insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiée par i.i''.Gouvernement de.la Province/Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, ROCII LEFEBVRE, Queen's Printer \u2014 Québec 9076 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 3 avril 1965, 97' année, No H Tarif des annonces, abonnements, etc, Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les «leux versions).Insertions subséquentes: 10 f Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of February, 1005.Raymond Doiville, Assistant Secretary of the I'rorince.10I85-o 424-65 Bond Concrete Floors.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I«oi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «laie du 23e jour «le février 1905, constituant en corporation: Nicola De Marco, 0207, Iberville, Michèle Petrella 7467, Birman, tous «leux finisseurs de ciment, «le Montréal, et Emile Poliseno, agent, 7511, 20e Avenue St-Michel, pour les objets suivants: Exercer uu commerce d'entrepreneurs en finissage «le planchers, sotufle nom «le « Bond I oncrete Floors, Lt«l.», avec un capital total île $35,000, divisé en 150 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 23e jour «le février 10(55.Le Sous-secretaire de la prorince, Raymond Dor ville.10185 780-65 Bond Concrete Floors.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 23r«l day of February.1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec.incorporating: Nicola De Marco, 9207 Iberville, Michel.' Pet relia.7467 Birman, both cement finishers, of Montreal, and Emile Poliseno, agent, 7511.20th Avenue, St-Michel, for the following purposes: To carry on the business of Hoof-finishing contractors, uiuler the name of \"Bond Concrete Floors, Ltd.\", with a total capital stock of $35,000.divided into 150 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company will !>«¦ at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 23rd day of February, 1905.Raymond D«»r ville.Assistant Secretary of the 1'rovinc.e.10185-o 780-65 Boulevard Steak House & Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 19e jour de février 1965, constituant en corporation: Albert Malouf, avocat et conseil en Boulevard Steak House & Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quelle Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Ma-luof, advocate and Queen's Counsel, 1100 Marl- 2078 {GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉIIEC, .{ avril 1965, 97' année.No IJ, Loi de lu reine.1100, Marlboro Drive, Mont Koyul, Bruno Pisteras, 11818, Frigon, Montréal.Vvun Maeerolu, 20!K), place Etienne-Brûlé, Montréul, et .lûmes Galileo, 0050, rue Stuurl.Montréal, ces trois derniers avocats, pour les objets suivants: Exercer un commerce de restaurateurs, sous le nom «le « Boulevunl Steak House & Restaurant Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 400 actions ordinaires «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 0020, boulevard St-Laurent.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce lite jour de février 1905.le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.10188 773-05 bono Drive, Mount Royal, Bruno Pateras, 1181s Prigon, Montreal, Yvan Macerola, 2090 Etienne Brûlé Place, Montreal, and .lames Galileo, 0959 Stuart Street, Montreal, the latter three advocates, for the following purposes: To carry on business as restauruteurs, under the name of \"Boulevard Steak House & Rest an -rant Inc.\", with a total capital stock of $10,001».divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company will be at 9020 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1 fitli day «)f February, 1905.Raymond Don ville.Assistant Seeretari) of the Province.ioisô-o 773-65 Brown-Wfnlow Compara) Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première parti «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Quék'c, «les lettres patentes, en u Ruisseau,St-Laurent, M oses (Moe) Williams, travailleur de syndicat ouvrier, et Pearl Marco-vil z, ménagère, épouse séparée dejiiens dudit aloses (Moe) Williams, et dûment autorisée par ce dernier aUX fins «les présentes, ces deux derniers de 2665, avenue Kent, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le restaurateurs, sous le nom «le « Au Chalet Doré inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A » de $1 chacune et 20,000 Au Chalet Doré inc.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, taaring date the 12th f $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company will be al Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 20th day «>f February, 1965.Raymond Don ville.Assistant Secretaru of the Province.10185-o 897-65 ' Computer Consultants Corporation Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 3rd day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Raymond Eric Parsons, 60 Chesterfield Avenue, James Hugessen.41 Thornhill Avenue, David Terence Dingle, 443 Mount Stephen Avenue, all three of Westmount.Michael Dennis, 3300 Ridgewood Avenue, Graham Nesbitt, 1519 Pine Avenue West, both of Montreal.Michael Kevin Smyth.173 Brittany.Mount Royal, all six advocates, and John Fraser Martin, stu«lent-at-law, 691 Allion Avenue, LaSalle, for the following purposes: To act as Consultants ami advisers in connection with the formulation and execution «»f solu tions to business, management, financial, scientific and related problems to which computer applications are appropriate, under the name ol \"Computer Consultants Corporation\", with ;i capital divided into 10,000 common shares without par value.The head office of the company will be at 1824 Sun Life Building, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of February, 1965.Raymond Dou ville.Assistant Secretary of the Province.10185-o 472-65 Créations Dinu inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 22e jour «le février 1965, constituant en cor- Créations Dina inc.Notice is hereby given that under Part I \"i the Quebec Companies Act, letters paten], bearing date the 22nd day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor ol the Province of Quebec, incorporating: Israel QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 3, 1965, Vol.97, So.U 2081 poration: Israel Tyberg, marchant!, Dina Ty-l>erg, ménagère, épouse séparée de biens dudit Israel Tyberg, tous deux de 381, Edward C lia ries, Montréal, Samuel Tyl>erg, marchand, 5030, De-cellcs, app.12, Montréal, et Herman Zvi Tyberg, marchand, 2785, place Darlington, app.31, Montréal, pour les objets suivants: Exercer un commerce de bijoutiers, sous le non de « Créations Dina Inc.», avec un capital total de $40,000.«livisé en 1,000actions onlinaires ,le $10 chacune et 3,000 actions privilégies «le f a real estate, cons truction and investment company, under the name of \"Les Entreprises Paul Brodeur inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be al Montreal, judicial district of Montreal.Given »t the office of the Provincial Secretary, this 22nd day of February, 1965.Raymond Dor ville, Assistant Secretaru of the Province.10185-u 824*65 The Federation of Schools of Nursing Assistants of Quebec.Inc.Lu Fédération d'écoles de garde-malades du Québec, inc.Notice is hereby given that uiuler Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 2nd day of March.1985, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporât as a corporation without share capital: Mary Elisabeth Rowan, 430 (îrosvenor Avenue, Westmount.Ade Gibbs, 1766 Cedar Avenue, Montreal.Mar garet Esther Sheila Donovan, 5429 Duquette Avenue, Montreal, Mary Blakey.6430 Sherbrooke Street West, Montreal, Mary Lennon.5187 Belmore Avenue, Montreal, all five secretaries, spinsters, ami Michael Deiinis.advocate.3300 Ridgcwotxl Avenue, Montreal, for the following purposes: To promote a uniform standard of excellence in schools of nursing assistants, under the name of \"The Federation of Schools of Nursing Assistants of Quebec, Inc.\u2014 La Fédération d'écoles de garde-malades du Québec, inc.\".The amount to which the value «>f tin* immoveable property which may be owned or held by the corporation, is to be limited, is $100.000.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2n«l day of March, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretaru of the Province.10185-o 961-66 Hochelaga Mortgage Inc.Les Hypothèques Hochelaga inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, incorporating: Irving L.Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, Daniel Kingstone, 4985 Iona Avenue.an«l Brahm L.Campbell, 5500 Snowdon Avenue, the latter tow of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hochelaga Mortgage Inc.\u2014 Les Hypothèques Hochelaga inc.\".with a capital stock divided into 2.000 common shares of a par value of $1 each, 10.000 class\"A\" preferred shares of a par value of $1 each, 26,000 class \"B\" preferred shares of a par value of $1 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April $, 1905, Vol.97, So.IJ, 2083 privilour découvrir des mines et minerais, sous le nom «le « MeMaster Québec ltée ».svcc un capital-actions «livisé en 10*000 actions ordinaires sans valeur au pair et 00.000 actions privilégiées «le |] chacune.Le siège social «le la compagnie sera 150, rue Craig, ouest, chambre 010, Montreal, district judiciaire de Montréal» Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 10e jour «le février 1005.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond I)orville.101 s:> 646-66 Montreal Time Realties Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la l^oi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 24e jour «le février 1005, constituant en corporation: Pascal Dipaolo, courtier 780, .larry, Montréal.Jean-Pierre Dostaler, courtier.297.Parkdale, Rosemère, et Roland Robillanl, avocat, 446, Lansdowne, Rosemère, pour les objets suivants: Exercer les affaires «l'une compagnie d'immeubles, sous le nom «le « Montreal Time Realties Inc.».avec un capital total de 81,000.«livisé en 100 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 780.rue Jarry, ouest.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné un bureau «lu secrétaire de la province, ce 24e jour «le février 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doiville.101 s:, 16-65 Montreal-Toronto Thru Way Restaurant Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première par de «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la tary, spinster, 5512 Silverson Avenue, Montreal, for the following purposes: To aet as consultants ami advisors to the manu gement and executives of any commercial enterprise, industrial organization or government.-, under the name of \".Management Science Corporation Ltd.\", with a capital divided into n.ihh> common shares without par value.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of February, 1066.Raymond Doi.'ville.Assistant Secretary of the I'rorince.10185-»» 760-65 McMuster Québec ltée Notice is hereby given that under Part I i the Quebec Companies Act, letters patent, liea ling date the 10th day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: André Vali-quette, lawyer.3340 Beauséjour, St-Laurent.Thérèse Beaulieu.secretary, wife separate as to property of Jean Ouellette, 51 Lavigne Street, apt.2, Ste-Geneviève, ami Guy (iervais, student, 3245 Linton Avenue, apt.11, Montreal, for the following purposes: To prospect and explore for mines and mine rals, under the name of \"MeMaster Québei ltée\".with u capital stock divided into 10,000com mon shares having no par value and 90,000 pre ferre»! shares of $1 each.The head office «»f the company will lie at 159 Craig Street West, Suite 919, Montreal judicial district of Montreal.(Jiven at the office of the Provincial Secretary this 10th day of February, 1965.Raymond Doiiyille.Assistant Secretaru of the Province.10185-o 546-65 Montreal Time Realties Inc.Notice is hereby given that under Part I \u2022>! the Quebec Companies.Act, letters patent, bearing «late the 24th ilay of February.1965, have been issued by the Lieutenant-Governoro! the Province of Quebec, incorporating: Pascal Dipaolo.broker, 780 Jarry, Montreal* Jean-Pierre Dostaler, broker.297 Park»lale, Rosemère, ami Roland Robillard, lawyer, 446 Lansd»>wne, Rosemère, for the following purposes: To carry on the business of a real estate coin pany, Under the name of \"Montreal Time Real ties Inc.\", with a total capital stock of 81*000.divided into 100 common shares of $10 each.The hea»l office of the company will be at 780 Jarry Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 24th day of February, 1965.Raymond Dou ville, Assistant Secretaru of the Province.10185-o 16-6\" Montreal-Toronto Thru Way Restaurant Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1965, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.April 3, I9(iô, Vol.97.No.U, 2066 province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 20e jour de janvier 1005, constituant en corporatism: Joseph P.Miller, avocat, 120, 00e avenue, LaSalle, Carmen Mouette, secrétaire, célibataire, 1985, rue Springluud, Montréal, et Vvon Ostiguy.commis, 81, rue Ostiguy, Laval-trie, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le restaurateurs, apua le nom «le r the follow mil: purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Nami Investments Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office «>f the company will be at 4890 Circle Road, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 1st day «>f February.1905.Raymond Dolville, Assistant Secretary of the Prwince.10185-c 487-05 National Restaurant Kquipment Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 12th «lay of February.1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Samuel Godinsky, Q.c.731 Upper Belmont Avenue.Westmount.Reuben Resin, 5510 Robinson Avenue, (Y>te-St-Luc.both advocates, ami Aniceta O'Grady, secretary, spinster, 4012 Hampton Avenue, Montreal, for the following purposes: To manufacture foo«l service equipment of all kinds, uiuler the nume of \"National Restaurant Kquipment Inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value f February, 1905.R a ymon d 1 )ol' ville, .\\ssistant Secretary of the Province.10185-o 691-65 2080 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, -i avril 190», 97' année, Xo U Norchem Industries lin-.Avis est donné qu'en vertu «le la premiere partie de la Loi «les compagnies «le Quebec, il a «'\u2022té a«-cor«lé, par le lieutenant gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 17e jour de février 1065, constituant «-n corporation: Jodah Lyon Wolofsky, 4165, avenue Esplanade, Montréal, Bernard Robert Benson, 052, avenue Lansdowne, Westmount, Arthur Marcovitch, 5525, avenue Trent, Côte-St-Luc, tous trois avocats, et June Sullivan, secrétaire, épouse séparée de Liens de William .loues, 5, Busile-Daignault, St-Basilc-lc-< irand, pour les objets suivants: Manufacturer t négocier toutes sortes de produits chimiques, teinture, savon, détergents, Composés et produits et.sous-produits similaires «le toutes sortes, sous le nom de « N'orchein Industries Inc.», uv«' property of Aron Korman, 1105 Marlatt, St-Laurent, am! Lucette Groliau, secretary, wife separate as to property of Claude Beaupré, 1091 Iberville Street, Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, uiuler the name of \"Place Décarie Light Lunch Inc.\", with a total capital capital stock of $40.000.divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 3, 1996, Vol.97, No.1A 2087 Le siège sociul tie la eontpaguie sera 5250, avenue Kerrier, Montréal, district judiciaire «le Montreal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 10e jour de février 1965, Le Sous-secrétaire de la puni née, Raymond Dou ville.uns;.772-65 Ititleo Limited Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, eu date du 10e jour «le janvier 1965, constituant en corporation: Gilles Rivanl.415, Lj-mesurier.Michael Hicksou, 330.Richelieu, tous deux avocats, de Québec, Jacques Jolicoeur, comptable 65, Des Boujeaux, Québec, Pierrette Caron.secrétaire.célibataire, 100, Crémazie, est, Québec, et Yolande Perreaull, secrétaire, célibataire, 38, I i'ite-du-Passage, Levis, pour les objets suivants: Manufacturer des appareils de chauffage et de climatisation de l'air, et en faire le commerce, sous le nom «le '« Rittco Limited ».avcf the Provincial Secretary, this lOth day of January, 1965.Raymond Dor ville, Assistant Secretaru of the I'rorince.10185-0 832-05 Romano Upholstering Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 10e jour de février 1905, constituant en corporation: (lino Romano, bourreur, 9497, Hamelin, Arthur Marcovitch, 5525, Trent, et Richard Gottlieb, 2900, Maplewood, ces deux derniers avocats, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés en amcublemnet, sous le nom «le « Romano Upholstering Inc.», avec un capital total «le 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées «le 81 chacune.Le siège social de la compagnie sera 0480, Hamelin, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de février 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dolville.10185 710-05 Sahara Auto Sales Limited Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 20e jour de février 1905, constituant en corporation: Andrée Turcotte, secrétaire, célibataire, 40, des Ormes, Québec, Yves Boiteau, comptable, 220, d'Iberville, Québec, et Jean MeNicoll, avocat, 1088, chemin (lomin, Sillery, pour les objets suivants: Romano l'pholstcring Inc.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 19th f \"Romano Upholstering Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20.000 prefcrreil shares of $1 each.The head office of the company will be at 9480 Hamelin, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 19th day of February, 1905.Raymond Dou ville, Ass ita nt Secret an/ of the Province.10185-O 710-05 Sahara Auto Sales Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Andrée Turcotte, secretary, spinster.40 des Ormes, Quebec, Yves Boiteau, accountant, 220 d'Iberville, Quebec, and Jean McNicoll, advocate, 1688 (lomin Road.Sillery, for the following purposes: 2088 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, .3 avril 1900, 97' année.So U Pain le commerce «le véhicules uutomobiles, sous le nom «le « Sahara Auto Sales Limited », avec un eupital total «le $20.000, divise en 400 actions ordinaires «le $10 chacune et 1,000 actions privilégiées «le $10 «\u2022hacune.Le Siège sociul «le la compagnie sera à Mont- reaJt «listrict judiciaire «le Montreal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ee 20e jour de février 101).\").Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvilue.10185 040-05 Scam Enterprises Inc.Avis est donné «(u'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a «'\u2022té accortlé, par le lietitenunt-gouverueur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 25e jour de février 10(55, constituant en corporation: Samuel ('hait.CH., 4, Surrey Gar«lens, Westmount, Arthur I.Hroustein, 5703, avenue Êldridge, Côte-St-Luc.et Robert S.Litvack.5217, avenue Ponsnrd, Montréal, tous trois av«x'ats, pour les objets suivants: Exercer un commerce «le constructeurs et entrepreneurs en construction, sous le nom «le « Seam Enterprises Inc.», avec un capital total «le $50,000, «livisé en 500 actions «mlinaires d'une valeur au pair «le $1 «diacunc.500 actions privilégiées catégorie « A » «l'une valeur au pair «le $1 chacune et 49,000 actions privilégiées catégorie « B » «l'une valeur au pair de $1 chacune.]a?siège stx'ial «le la compagnie sera à chambre 3035, 1, place Ville Marie, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ee 25e jour «le février 1905.I^e Sons-.secrefaire de la province, Raymond Dorville.10185 820-05 Samuel S.Segal Investments Inc.Avis est «lonné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 21e jour «le janvier 1905.constituant en corporation: Robert S.Lilvack, 5217, avenue Ponaard, Montréal, Nathaniel IL Salomon.4300, avenue Western, Westmount, Bernar»! Reis, 595, avenue Bloomficld.app.8.Montréal, et Hahum Gelbert, 4115, Jean-Brillant, Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants : Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, «le construction et «le placements, sous le nom de « Samuel S.Segal Investments Inc.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 1.000 actions ordinaires «l'une valeur au pair «le $1 chaciuic.2,000 actions privilégiées catégorie IA S d'une valeur au pair «le $1 chacune et 970 actions privilégiées catégorie « B » «l'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 135, avenue Van Horne, Montréal, «listrict judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 21e jour «le février 1005.I* Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Dor ville.10185 245-05 Shawbridgc Golf Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de lu première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la To deal in motor vehicles, under the name of \"Sahara Auto Sales Limited\", with a total capital stock of $20,000, divided into 400common snares of $10 each and 1.000 preferred shares of $1(1 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial «listrict of Montreul.Given at the office of the Provincial Secretary this 20th day of February, 1066.Raymond Dor ville, Assistant Secretaru of tin Province.10185*0 040-65 Seam Enterprises Inc.Notu-e is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 25th day of February, 1905.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «»f Quebec, incorporating: Samue! ('liait.Q.C.I 4 Surrey Gardens, Westmount.Arthur I.Bronstein, 5703 Eldridge Avenue.( ote-St-Liu-, and Robert S.Litvack, 5217 Pon- sard Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of builders ami i mild i: contractors, under the name of \"Scam Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $50,00(1, divided into 500 common shares of a par value of 81 each, 500 class \"A\" preferred shares of a par value of 81 co.c\\\\ ami 49,000 class \"B\" preferred shares f a par value of $1 each.The head office of the company will be at Suite 3035, 1 Place Ville Marie, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 25th day of February.1905.Raymond Dor ville.Assistant Secretary of the I'rorince.10185-0 826-0.5 Samuel S.Segal Investments Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 21st day of January, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Robert S.Litvack, 5217 Ponsard Avenue, Montreal, Nathaniel H.Salomon.4300 Western Avenue.Westmount, Bernard Reis.595 Bloomficld Av« \u2022 nue, apt.8, Montreal, and Hahum Gelber, 4115 Jean-Brillant.Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction ami investment company, under the* name of \"Samuel S.Segal Investments Inc.\", with a total capital stock of 8100.000.divide : into 1,000 common shares of the par value of $1 each, 2.000 class \"A\" preferred shares of the par value of $1 each and 970 class \"B\" preferred shares «»f the par value of $100 each.The head office of the company will be at 135 Van Horne Avenue, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 21st day «>f February, 1966.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.10185-o 245-05 Shawbridgc Golf Holdings Limited Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, beuring date the 17th day of February, 190*', QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, April S, 1905, Vol.97, No.11 2089 province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 17e jour «le février 1905, constituant en corporation: T.l'aimer Howard, ch., avocat, 0, chemin De Casson, Westmount, Alexander McTavish Stalker, avocat, 40, avenue Cornwall, Mont Royal, et Robert James Stocks, avocat, 1725, avenue (îrosvenor, Montreal, pouf les objets suivants: Kxercer les affaires «l'une compagnie «le portefeuille, sous le nom de I Sliuwhridge Golf Holdings Limited », uvec un capital total de 850,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Shaw-hridge, «listrict judiciaire «le Terrebonne.Donné un bureau du secrétaire «le la province, ce 17e jour «le février 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.10185 535-05 Si lac Construction Ltd.Silac construction ltée Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 22e jour «le février 1965, constituant en corporation: Donald Massad, courtier, Diane Rodrigue, ménagère, é|>ouse séparée «le biens dudit Donald Mussad, tous «leux «le 330, Hauterive, Duvernay, et Ralph Massad, commis 330.Melbourne, Montréal, pour les objets suivants: Kxercer le commerce d'entrepreneurs généraux, «nis le nom «le « Silac Construction Ltd.\u2014Silac construction ltée ».avec un capital total de $500,000, «livisé en 500 actions ordinaires «le $10 chacune et 4,950 actions privilégiées de 8100 chacune.\u2022 Le siège social «le la compagnie sera 3206, rue Jarry, est, Montréal, district judiciaire «le Montreal.\" Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 22e jour «le février 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.10185 818-65 Silma-Sonik (Canada) Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 10e jour de février 1065, constituant en corporation: George «le Lanau/.e.Louis de Lanau/.e, 1027.rue Blcury et Walter Lee, 768, Jean-Talon, ouest, tous trois administrateurs «le Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'Images photographiques, vues animées et fixes, accessoires et outillage, -oils |c nom de « Silmu-Sonik (Canada) Ltd.», avec un capital total «le 840*000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le 810 chacune et 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 708, Jean-Talon ouest, Montreal, «listrict judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 10e jour «le février 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10185 775-65 Star Stainless Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixn «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating : T.Palmer Howard, Q.6», advocate, 0 De Casson Road, Westmount, Alexamler M«>Tavish Stalker, advocate, 40 Cornwull Avenue, Mount Royal, and Robert James Stoeks, advocate.4725 Grosvenor Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Shawbridgc Golf Holdings Limited\", with a total capital stock of 850.000, divided into 5,000 common shares of $10 each.The head office of the company will he at Shawbridge, judicial district of Terrebonne.Given at the office «)f the Provincial Secretary, this 17th day of February, 1965.Raymond Dor ville, Assistant Secretaru of the Province.10185.) 535-05 Silac Construction Ltd.Silac construction ltée Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 22nd day of February.1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Donald Massed* broker, Diane Rodrigue, housewife, wife separate as to property «>f the said Donald Massad, both of 330 Hauterive, Dim-may.and Ralph Massad, clerk.330 Melbourne, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of general building Contractors, under the name of \"Silac Construction Ltd.-Silac construction ltée\", with a total capita] stock «>r $500,000, divided into 500 common shares of $10 each ami 4.950 preferred shares of $100 each.The head office of the Company will be at 3200 Jarry Street Fast, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office «>f the Provincial Secretary, this 22nd day of February.1965.Raymond Dor ville, Assistant Secretaru of the Province.10185-o 818-65 Silma-Sonik Canada Ltd.Notice is hereby given that uiuler Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: George «le Lanause, Louis de Lanauee, of 1027 Bleury Street, and Walter Lee, 708 Jean-Talon West, all three executives, of Montreal, for the following purposes: To f the company will be at 12145 Laurent iun Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 20th day of February, 1005.Raymond Douville, Assistant Secretaru of the Province.10185-o 901-65 Torch Ski Area Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 20th day of February, 1905.have been issued by the Lieutenant-Goçrnor of the Province of Quebec, incorporating: William John Hulbig, a«lvocate, 299B Grosvenor, West-mount, Donagh Rutgers, legal assistant, 521.39th Avenue, Lachine, and Jane Arlyess Hamilton, secretary, spinster.1S30 Lincoln Avenue.Montreal, for the following purposes: To carry on the business of establishing and operating recreational resorts including skiing ami hotel facilities, uiuler the name of \"Torch Ski Area Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 4,000 common shares of the par value of $10 each and 3,000 class \"A\" shares of the par value of $20 each.The head office of the company will be at Sutton, judicial district of Bedford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 26th day of February, 1965.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.10185-o 798-65 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April J, 1905, Vol.97, So.Ik 2091 Les Transformateurs de Québec inc.Quebec Transformers Inc.Dans l'avis de lettres-patentes publié dans lu Gazette Officielle- de Québec .lu 20 juin 1004, à la page 332\").veuillez reinplucer dans le titre le mot « transformations » par le mot f the Provincial Secretary, this 24th day of February, 1005.Raymond Dor ville.As.si.-tant Secrcturi/ of the Province.101S5-o 858-65 Verdun Auto Parts Inc.Notice is hereby given that under Part.I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing «late the 1st day of March, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Barbara Joyce (Jarrett.secretary, wife separate as to property of David Charles Hopkins, and duly authorize*! by him for the purpose of these presents, 74(H) Kingsley Road, Apt.007, Montreal, Anne Goldenberg, secretary, 3491 Atwater Avenue, Montreal, and Lise Walton, secretary, 815 Cardinal, Montreal, the latter two filles majeures et usant «le leurs droits, for the following purposes: To deul in automobile accessories, under the name of \"Verdun Auto Parts Inc.\", with a total capital stock «>f 840,000, divided into 200 class \"A\" shares of the par value of 810 each, 200 class \"B\" shares of the par value of S10 each and 3,000 preferred shares of the par value of 810 each.The head office of the company will l>e at Verdun, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of March, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.10185-o 944-65 Yorheau Mines Inc.Notice is hereby given that uiuler Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Thomas Stuart Gillespie, advocate, Westmount, Ernest William Mockridge, manager, St-Lambert, Clifford George Meek, bookkeeper, Montreal, Charles Eric Humphrey, l>ookkeeper.Verdun, and 2092 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, $ avril I960, 97' année.So l\\ livres, Verdun, et Colin Richard Chlsbolm, commis, Montreal, pour lei objets suivants: Faire «les recherchée et explorations pour «lé- OOUVrîr «les mines et minerais, sous le nom «le « Yorbeau Mines Inc.».avec un capital-action* divisé en 5,000,000 d'actions sans valeur au pair.Le singe social «le la compagnie sera à Chibou-gémeau, «listrict judiciaire d'Abitibi.Donné au bureau «lu secrétaire «!«\u2022 la province, ce Oe jour «!«\u2022 février 1065.Le Suu.s-.sifrétai re tir la priai née, Raymond Doi ville.lois;, 547-65 080 St.Antoine Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la loi «les compagnies «le Quebec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur «!«¦ la province «!f the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 11 Lit day of February, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.