Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 17 (no 29)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1965-07-17, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Québec, samedi 17 juillet 1965 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Impri-innir de la reine, Hôtel du Gouvernement, ec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif \"lliciel.3° Indiquer le nombre d'insertions.1° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., Mint strictement payables d'avance.b° Tout paiement doit être fait par chèque on mandat à l'ordre du Ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le uunedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins nue ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents \"ii annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la raine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.S° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés «l'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Saturday, Julj 17.1965 Rules 1.Address all communications to: The Queen's Printer.Parliament Buildings, Quebec.2.Supply advertising copy in the two official languages.When copy i> supplied in one language only, the translation will lie made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for advertising copy according to the rates set forth balow, exception when the copy is to be published several times.In that event, the interested party shall pay upon receipt f his account and before the second insertion: otherwise this insertion will be suspended without further notice an'd without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price »»f documents, etc., are payable strictly in advance.G.Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on U'eilnesilay, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.PUBLIÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE / PuBUSUEl) BY.THE PROVINCIAL GOVERNMENT L'Imprimeur de la reine, KOCH LEFEBYRE, Queen'g Printer \u2014 Québec 3830 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, t> juillet IM6, 07' année, Sa 20 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première Insertion! 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (Il lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire ilistes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: SI des 100 mots.Exemplaire Réparé: 10 cents chacun.Feuilles vidantes: SI.50 la douzaine.Abonnement: SIC) par année.N.B.\u2014 Les chiffrai placée au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition «le la Guzcttc pour la première insertion; le troisième ù celui «lu nombre d'insertions, et la lettre « o» signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de noire numéro «le facture.VImprimeur de lu reine, Roui LbfebvBJB.Hôtel du Gouvernement, Québec, 5 mai 1902.S903 - 1-52-0 Lettres patentes Alfred Door Alaintenanec Ltd.Avis est donné qu'en vertu de Is première partie de la Loi des compagnies de Québec, il ;> été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, eu date du 7c jour «le juin l!l(i.\">.constituant en corporation: Pierre (i.Bouchard, avocat, 11810, dames Morrice, Marcel Hamelin, notaire.12086, L'Aca- die, et Pauline Sinianl.secrétaire épouse séparée «le biens «FAn«lrée Simard 0302, Chateaubriand, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Paires affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en const met ion.sous le nom \u2022le « Alfred Door Maintenance Ltd.», avec un capital tolul «le $30,000; divisé en 150 actions ordinaires «le SI00 chacune et en 150 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Mont* réal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour «le juin 1905.Le Sous-secrétaire île la province, Raymond Dotjvillb.11416-0 2467-66 Arthur Allaire liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du Ne jour «le juin 1965, constituant en corporation: Arthur Allaire, entrepreneur, 2610, ave Bardy.Québec, Bernardin BlancheL avocat, ISO, «le Bernières, Québec, et Jules Blanchet, avocat, 890, Begin, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Arthur Allaire liée », avec un capital total «le $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Advertising, Kates, Subscriptions, etc.First incertain: 30 cents per agate line, for each version, (11 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Sul>se«|Uenl insertions: 10 «ruts per agate line fur each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc at double rate.Translation: $1 per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: SI.50 per dozen.Subscriptions: $10 per year.X.IL\u2014The figures at the bottom of notice* have the following meaning: The first figure refers to «>ur document number: the second to that of the edition of the Gazett-for the first insertion; the third to the number ol insertion, ami the letter Mo\" signifies that the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but «>nce are followed only by our document number.Rocs Lkfedvkk, Queen s Printer.Parliament Buildings, Quebec.May 5, 1962.8903 \u2014 1-52-.Letters Patent Alfred Door Muintenance Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 7th «lay of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Ciovernor of tin-Province of Quebec, incorporating: Pierre (>.Bouchard, lawyer, 11S10 James Morrice, Marcel Hamelin, notary, 12080 L'Aca«lie, and Pauline Simard, secretary, wife separate as to pr«>|)crty of André Simard, 9302 Chateaubriand, all three of Montreal, for the following purposes: Tn carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"Alfred Door Maintenance Ltd.\", with a total capitul stock «>f S30.000, divided into 150 common shares of SI00 each and into 150 preferre«l shares of s 100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretary, this 7th day of June, 1905.Raymond Douyillb, Assistant Secretary of the Province.11415 2407-05 Arthur Allaire liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 81 h er-ville, and Pierre Alix, professor, 275 Riendeau Street, Iberville, for the following purposes: To renew, maintain ami extend friendly relations among the alumnae of the school, under the name of \"Amicale Mariste d'Iberville, incorporée\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $10,000.The head office of the corporation will be at Iberville, judicial district of Iberville.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of June, 1965.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.11415 2734-65 Antony Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Max Slapack, advocate and Queen's Counsel, 5562 Glencrest Avenue, Côte-St-Luc, Arthur Shulman, advocate, 3445 Ridgewood Avenue, Montreal, and Monroe Charlap, student, 2990 Soissons Avenue, Montreal, for the following purposes: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 19Û6, 97' année, Sa .\u2022'¦> 3832 Dessiner, manufacturer et faire !»\u2022 commerce d'articles ai matériaux utilises «lims la fourniture île l'éclairage OU s'y rapport, soils le nom de i Anlouy [ne.avec Un capital total our les objets suivants: Promouvoir et encourager «le toute manière l'habile conduite automobile sur la voie publique, sous le nom «le « Club auto Drummond inc.\u2014 Auto Club Drummond Inc.».I^e montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $25,000.Le siège social de la corporation sera à Drum-uiondville, district judiciaire «le Drummond.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 7e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415m 2505-05 Le Club Cherrier inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la provint* de Québec, «les lettres patentes, en «late du 12e jour de mai 1905, constituant en corporation sans capital-actions: Georges Berthiaume, gérant 6816, Christophe-Colomb, Montréal, Roger Bélanger, organisateur général, 10859, Lon-«lon, Montréal-Nord, et Lucien Boivin, capitaine pompier, 2530, Nicolet, app.2, Montréal, pour les objets suivants: Établir et exploiter un club social et sportif, sous le nom de « I^e Club Charrier inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acqué-rir et posséder, est «le $100,000.Le siège social de la corporation sera à Mont-tréal, district judiciaire de Montréal.bearing date th«' 4tli day «>f June, 1*105, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, to incorporate as a corporation without ¦hare capital: Albert Owen Aikin, 2790 Valcourt, Bte-Foy, Samuel Pederic Tim- merman Jr., 1490 Sir George Simpson, ami Jerry L.Davidson, 4465 Sherbrookf Lacliine, all three preachers of the Gospel, for the following purposes: To establish and maintain a Chuivli and to carry on the teachings of the Gospel, under the name of \"The Church of Christ in Quebec District [ne.-L'Eglise «lu Christ du district de Québec inc.\".The amount to which the value «>f the immoveable property which the corporation may possess or hold, is t«) be limited, is 61,000,000.The head office of the corporation will be at Ste-Foy, judicial district of Quebec.Given at the office of the Provincial Secretary! this 4th day of June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secret'an/ of the Province.11415-0 238745 Club auto Drummond inc.Auto Club Drummond Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 7th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Denis Goodrum, agents, 1190 St-Joseph Boulevard, Drummon- ville South.Charles Adam, trader, 700 Gall Boulevard, ami Bernard (iuay.manager, 121 Gall Boulevard, the latter two of Drummond ville West, for the following purposes: To promote and encourage in every way skilful automobile driving on public roads, under the name of \"Club auto Drummond inc.\u2014 Auto Club Drummond Inc.\".The am«)unt to wich the value of the immoveable properly which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is §25,000.The head oflice of the corporation will be at Drummond ville, judicial district of Drummond.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 7th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.H415 2505-65 Le Club Cherrier inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 12th day of May, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Georges Berthiaume, manager.6816 Chrislophe-Colomb, Montreal, Roger Bélanger general arganizer, 10859 London, Montreal-North, ami Lucien Boivin, fire captain, 2530 Nicolet, Apt.2, Montreal, for the following purgses: To establish ami operate a social and sports club, initier the name of \"Le Club Cherrier inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may is to be limited, is 8100,000.The head office «)f the corporation will b«' at Montreal, judicial district of Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 11 juillet 1966, 9P année, No «9 3836 Donné au bureau «lu secrétaire de la province) ce 12e jour de mai 1666.lé Soitê-eecrêtaire de lu province, Il wmom) Dorvn.i.k.11415-.2234-65 Chili sportif Laurentien (1965) A vil est donné qu'en vertu de In troisième partie de la Loi «les compagnies «h- Québec, il ¦ été accordé, par le lieutenant \u2022gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de juin 1965, constituant en corporation sans capital actions: Guy IVlletier, industriel, Nicole Larouche, secrétaire, épouse séparée «le biens dudit Guy Pelletier, tous deux de 3, boulevard Si -Pierre, et Man- Pelletier, soudeur, 508, avenue Notre-Dame, tous trois de Notre-Dame-des-Laurentides, pour les objets suivants: Etablir et diriger un club social, sous le nom de « Club sport if Laurent ieu (1965) \u2022 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers la corporation peut acquérir et posséder, est de 650,000.Le siège social «le la corporation sera à Notre- Dame-des-Laurentides, dis! ricl judiciaire «!f the Province, 11415 2574-66 !.\\.Daigneaull «X Ml- liée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent.bearing «late the 7th day of June.1965, have been issued by the Lieutenaut-(iovernor of the Province of Quebec, incorporating: Léo-Albert Daigneaull.merchant.André Daigneault, clerk, ami Lauréat Tardif, chartered accountant, all three of Cowansville, f«»r the following purposes' To carry on the business of all kinds «)f articles and merchandise w ch constitute a grocery business, under the name «»f \" L.A.Daigneault & fils It « '\u2022 « - \".with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head «>Uiiv f the company will be at Cowansville, judicial district «»f Bedford.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 7th day of June, 1965.Raymond Douvillb, .leeistani Secretary of Uu Province.1141Ô 2680-65 Les Dames auxiliaires de l'Hôpital Général du Saguenay I lu- Saguena> (.encrai Hospital Women Auxiliary Notice is hereby given that umlcr Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «laie the 9tll day «>f .func, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Clara Landry, housewife, wife separate as to property of Arthur Murray, 287 Cabot, Katharine Stevenson, housewife, wife separate as to property of (iaston Dufour, 232 Castner.ami Esther Barthe, housewife, wifw separate as lo property of Roger Giasson, llô Burma, all three of Arvida.for the following purposes: To promote the welfare of the Saguenay General Hospital ami of its patients, under the name of \"Les Dames auxiliaires de l'Hôpital Général tin Saguenay The Saguenay General Hospital Women Auxiliary\".The amount lo which the value «>f the immoveable property which the corporation may hold is to be limited, is $10,000.The head ollice of the corporation will be at Arvida, judicial district of Chicoutimi.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of June.1965.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of tin Province.114 lô 2604-65 Dipioin Electric Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent.bearing date the 9th day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Arthur Va- 3838 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet I960, 97» année.No 29 ration: Arthur Vanofsky, avocat, 5872, l'Vrn-croft, Hampstead, Julius Briskiu.avocat et conseil en loi «le la reine.134, Finchley, Hampstead, et Claire Culhane, secrétaire, oe^ibataire, 2100, Harvard, Montréal, pour les objet* suivants: Exercer le commerce d'une compagnie électrique et électronique, sous le nom de « Diplom Klectric Co.Ltd.\\ avec un capital total de $40.0(M), divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et 3,500 actions privilégiées de 810 chacune.Lé siège social de la «-«unpaguic sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de juin 1065.Le Sou*.secrétaire de la province, Raymond Doi vii.i.k.11415 2716-65 Di Vila Construction Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la piOVince de Québec, des lettres patentes, en date «lu 2e jour «le juin 1905, constituant en corporation: Joseph-Bernard Billard, Jacques Verdy, notaires, et Monique Billard, secrétaire, fille majeure, tous trois de 715, Carré Victoria, f 930, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaire comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom «le « Di Vita Construction Co.Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en l.ooo actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à LaSalIc, district jmliciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 2e jour de juin 1905./.c Sous-secrétaire de la province, Raymond Docvii.i.i:.I1415-0 2542-05 Domaine du golf (Lac Bcauporl) inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouvencur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 9e jour de juin 1905, constituant en corporation: Philippe Jolicœur, 940, St-Jcan, André Duval, 880, chemin Ste-Foy, tous deux notaires, .1.-Adrien Boivin, entrepreneur, 1189, de Cal-lières, tous trois «le Québec, André Bertrand, ingénieur, Roger Lavoie, industriel, tous deux de Lac-Beauport, et (iaston Michaud, avocat, 0835, Place Boivin, Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Domaine du golf (Lac Beauport) Inc.», avec un capital total de $150,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 1,200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Québec, district judiciaire de Québec.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 9e jour de juin 1905.Le Sous-sccrétairc de la prorince, Raymond DorviLLK.11415-0 2701-05 Les Entreprise» Bcrthier inc.Avis est donné (m'en vertu «le la première partie de la I.oi des compagnies de Québec, il a nofsky, advocate, 5872 Ferncroft, Hampstead.Julius Brisk in, advocate and Queen's Counsel, 134 Finchley, Hampstead.ami Claire Culhane, secretary, spinster, 2100 Harvard, Montreal, foi the following purposes: To carry on the business of an electrical and electronics company, under the name of \"Diploin Electric Co.Ltd.\",' with a total capital stock of $40.000.divided into 500 common shares of 610 each and 3.500 preferred shares of $10 each.The head office of the c»>inpnny will be al Montreal, judicial district of Montreal.(liven at the oflice of the Provincial Secretary, this 9th .lay of June, 1905.Raymond douvillk, Assistant Secretary at the Province.11415m 2710-0:.Di Vitu Construction Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, hearing «late the 2nd day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Joseph-Bernard Billard, Jacques Verdy, notaries, and Monique Billard, secretary, fille majeure, all three of 715 Carré Victoria, § 930, Montreal, for the following purposes: To carry «m business as a real estate ami construction company, under the name of \" Di Vita Construction Co.Ltd.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 1.000 common shares «>f $10 each and into 3.000 preferred shares «»f $10 each.The head office of the company will be at LaSallc.judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1905.Raymond DoUVILLK, Assistant Secretary of the Province.11415 2542-05 Domaine du go] i (Lac Beauport) inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters petent, bearing «late the 9th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Philippe Jolicœur, 940 St-Jean, André Duval, 880 Ste-Foy Road, both notaries.J.-Adrien Boivin.contractor, 1189 de Callières, all three of Quebec, André Bertrand, engineer.Roger Lavoie, in-dustralist, Both of Lac-Beauport, ami Gaston Michaud.lawyer, (J835 Place Boivin, Charles-bourg, for the following purposes: To Carry on business as a real estate and construction company, under the name of \" Domaine du golf (Lac Beauport) Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 300 common shares of $100 each and into 1,200 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company will be at Quebec, judicial district of Quebec.(Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of June, 1905.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.11415 2701-65 Let* Entreprises Berliner inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1966, Vol.97, So.29 3839 été accorde, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Quél>ec, des lettres patentes, en date du 3e jour 'le juin 1965, constituant en corporation: Rolland Sylvestre, cultivateur, Marie-\\nge Fernet, ménagère, eixnise séparée «le biens \u2022 111*lit Rolland Sylvestre, et Jean Sylvestre, cul-livaleur, tous trois de Hcrtliicr, pour les objets -ni vanta: Pain affairai comme compagnie de construction, sous le nom «le « Lea Entreprise! Berthier inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «le $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera rang Hivièrc-Bayonnc-Nord, Berthier, district judi-iliciaire de Juliette.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, re 3e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2634-05 Les Entreprises Claire Fontaine, ltée Avis est donné qu'en vertu de la première \u2022artie «le la Loi des compagnies de Quélx'c, il a té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du Se jour de juin 1905, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat et conseil en Loi de la reine, 1301, Sl-Yiateur, ouest, Outre-mont, Gertrude Bourdeau, 2660, Bercy, et Fernande IVrreault, 2825, Ixmlevard St-Joseph, est, i es deUX dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les opérations «l'une compagnie de portefeuille (holding); faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Les Entreprises Claire fontaine, ltée >, avec un capital total «le $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $10 chacune.Ix* siège social de la compagnie sera à St-I.anient, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 8e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dot;villi:.11415-0 2684-05 Farber's Plumbing & Heating Service (1965) Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a earing date the 3rd day of June, 1965, have baen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incoq>orating: Rolland Sylvestre, farmer, Marie-Ange Fernet, housewife, wife separate as to property of the said Rolland Sylvestre, and Jean Sylvestre, farmer, all three of Berthier, for the following purposesi To carry on business as a construction company, under the name of \"Les Entreprises Berthier inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will l>e on the Rivière-Bayonnc -North, Range, Berthier, judicial district of Joliette.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of June, 1066.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2634-65 Les Entreprises Claire Fontaine, ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quel>cc Companies Act.letters patent.I>caring date the 8th day of June, 1066, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incoqiorating: Maurice Martel, advocate and Queen's Counsel, 1301 St-Viatcur, West, Outremont, Gertrude Bourdeau.2660 Bercy, and Fernande Perreault, 2826 St-Joseph Boulevard, East, the latter two secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: To carry on the operations of a holding company; to act as restaurateurs, under the name of \"Les Entreprises Claire Fontaine, ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 1,000 common shares «>f $10 each and 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at St-Laurent, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary this 8th day of June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2684-65 Farber's Plumbing «& Heating Service (1965) Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Murray B.Spiegel, Harvey M.Coopcrslone.advocates, of 1010 Ste-Catherine Street West, Montreal, and Doris Chnsonoff, secretary, spinster, 1412 Elizabeth Boulevard, Chomedey, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"Farber's Plumbing & Heating Service (1965) Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 9th day of June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 2715-65 3840 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 17 juillet 1966, 97*.année, No 99 Ferguson Kcrr Ltd.Avi> est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi îles compagnies de Québec, il a f 8100 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(liven at the office of the Provincial Secretary.this 2nd day of .lune, 1865.Raymond Doivm.i.k, ' Assistant Secretary of the Province.11415-0 2567-65 Fondation P.Rodolphe Haril Notice is hereby given that under Part HI of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of May.1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: J.Kenneth Allison, department manager.5075 O'Hryan Street.Montreal, Roger Filion.director, 225 Irvine Avenue, St-Lambert, and (iuy Boucher, assistant director.03 Louis-Lacosle Street.Hoiichci- villc.for the following purposes: To constitute a philanthropic foundation, of charity and aid to education and science.Under the name of \"Fondation P.Rodolphe Hard\".The corporation will not acquire nor p«>ssess any immoveable property.The head office of the corporation will be at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC official GAZETTE, Jul,/ n, im,.Vol.;, \\\u201e.Donné au bureau «lu secrétaire de I» province) «\u2022«\u2022 l le jour «l«- mai 1965.Le 8outi-8ccrêtair~e de lu province, Raymond Dou ville, 11415-a 2295-65 ForgeI Petroleum Inc.\\\\is est donné qu'en vertu ne la première partie de la Loi de.-> compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 20e jf Abitibi-YYest.f«>r the following purposes?To build ami manage a home for the aged, under the name of \"Le Foyer Monseigneur Halde\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is t«> be limited, is 8250,000.The head office of the corporation will be at Palmarolle, county of Abitibi-West, judicial «lis- trtCt of Abitibi.(\u2022iven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of June.1965.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secreturi/ of the Province.11415 4673-64 Fuji Industrial Supplies I.id.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th «lay of June, 1 !\u2022(>.\">.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: (iuy-K.Hois-vert, 4070 (ileucairn.Montreal, G.Harold Pickel, 47 Arlington, West mount, and Claude Hois-vert.1505 Moore, Chomedey, all three advocates, f«>r the following purposes: To deal in all kinds of products, articles ami merchandises, under the name of \"Fuji Industrial Supplies Ltd.\", with a t«>tal capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of $1 each ami 3,900 preferred shares «»f S10 each. 3842 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 17 juillet 190Ô, 97' année, S'o 29 Le siège social de la compagnie sera 455, rue Craig ouest, chambre 502, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au Inireau du secrétaire de la province, ce le jour «le juin 1985.Le Sanssein'tuire île la province, Raymond Douvillk.11415 2057-05 (.aHand & frères limitée Avis est donné qu'eu vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur «le lu province «le Québec, des lettres patentes, en date du Se jour «le juin 1066, constituant en corporation: Héal (îallaiid, Jean-Charles (îullaml et Joseph-Albert (îullaml, commerçants, «le 3874, Du Souvenir, Chomedey, pour les objets suivants: Faire le commerce «le véhicules automobiles, s«uis le nom «le « (iallaml & frères limitée », avec un capital total «le §50,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 400 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 8874, Du Souvenir, Chomedey, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 8e jour de juin 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11416-0 2089-05 Curage Marc ltée Marc Garage Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la lx>i «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 10e jour de juin 1905, constituant en corporation: Olivier Gauthier, avocat, Ghislaine St-Aubin, ménagère, épouse contractucllement séparée de biens dudit Olivier Gauthier, tous «leux de 10420, rue Clark, Montréal, et Marie-Andrée Bourrassa, secrétaire, é|>ouse cou trac-tuellement séparée «le biens de René Martel, 1040, rue Gilford, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles et faire affaires comme garagistes, sous le nom de «Garage Marc ltée \u2014 Marc (îarage Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.I*e siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 10e jour «le juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2479-65 Maurice Gcndron inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 10e jour de juin 1965, constituant en corporation: Maurice Martel, avocat et conseil en Loi de la reine, 1301, rue St-Viateur, ouest, Outremont, Gertrude Bourdeau, 2560, Bercy, Montréal, et Fernande Pcrreault, 2825, boulevard St-Joseph, est, Montréal, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: The head oflice of the company will he at 466 Craig Street West, Room 502, Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the oflice of the Provincial Sceretan this Itlnlay of June, 1905.Raymond Dor vii.i.k, .Insistant Secretary of the Province.11415-0 8667.fi (.ill.uni & frères limitée Notice is hereby given that under Part I i the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the Bth day of June, 1905, hav.been issued by the Lieutenaiit-Covernor of the Province of Quebec, incorj>orating: Real (iallan.l Jean-( 'liarles ( .a I la i id and Joseph-Albert ( ialland traders, of 3874 Du Souvenir, Chomedey.foi the following pur|h>ses: To carry on business dealing in automobile vehicles, under the name «>f \"(ialland & frère.' limitée\", with a total capital stock of $50,000.divided into 100 common shares of $100 each and 400 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be s 3874 Du Souvenir, Chomedey, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary.this 8th day «>f June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi/ of the Province.11415 2689-60 G a rage Mare ltée Marc Garage Ltd.Notice is hereby given tliat under Part I «>l the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the Hit h «lay of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Olivier Gauthier, advocate, Ghislaine St-Aubin, housewife, wife contractually separate as to property of tin-said Olivier Gauthier, both of 10420 Clark St.Montreal, ami Marie-Andrée Bourassa, secretary, wife contractually separate as to property of René Martel, 1040 Gilford St., Montreal, f«»'r the following purposes: To carry on business dealing in motor vehicles, and to act as garagemen, under the name of \"Garage Marc ltée \u2014 Marc Garage Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2479-05 Maurice Cendron inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Maurice Martel, advocate and Queen's Counsel, 1301 St-Viateur St.West, Outremont, Gertrude Bourdeau, 2500 Bercy, Montreal, and Fernande Perreault, 2825 St-Joseph Blvd.East, Montreal, the two latter secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1905, Vol, 97, No.29 3843 Paire le commerce «le véhicules automobiles, de combustibles et lubrifiants; faire affaires \u2022 limine garagistes, sous le nom de « Maurice ( h-udron inc.avec un capital total de .$40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le S10 chacune 11 en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.|,e siège social de la compagnie sera 2230, rue lu aiiparlaut, St-IIyaciuthe, district judiciaire de St Hyacinthe.Donné au bureau du secrétaire de la province, ee 10c jour de juin 1985, Le Sous secrétaire de.la province, Raymond Douvillk.11416-0 2727-66 « .ill;un Corporation l.td.Avis est donné qu'en vertu de la première |.ntie de la Loi des compagnies de Québec, il a té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour de juin 1905, constituant en corporation: Monique Robitaille, secrétaire, tille majeure, 3020, Fullum, app.31, Montréal, Pierrette Baril, secrétaire, épouse contractuelle- ment séparée de biens de Pierre Baril, 1820, De l.orimier, Montréal, et Guy Valiqiicttc, comptable agréé, 2060, Régence, St-Bruno-de-Mon-larville, pour les objets suivants: Faire des recherches, des études, des expériences dans le domaine spatial, de la balliitiquc et des explosifs, sous le nom de « Giltaur Cor-lioration Ltd.», avec un capital total de $200,000, divisé en 18,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées de $5 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2075-65 Global Credit Corporation Corporation de crédit Global Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec1, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de juin 1965, constituant en corporation! Volker Mehnert, notaire, 6, Park Place, app.12A, Westmount, Herbert Klin-gner, comptable, 3955, avenue Dupuis, Montréal, et Soja Andrcjews, commis de bureau, épouse séparée de biens de Willy Berg, 211, Place Tall wood, Rosemère, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Global ('redit Corporation\u2014 Corporation de crédit Global », avec un capital-actions divisé en 25,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1155, boulevard Dorchester ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 3e jour de juin 1965.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415 2530-65 Gulfatream & Caribbean Realty Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la - To carry on business dealing in motor vehicles, fuels and lubricants; to act as garageinen, under the name of \"Maurice (î em Iron inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each ami 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at 22.30 Beau pariant St., St.Hyacinthe, judicial district of St.Hyacinthe.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 1905.Raymond Douvillk, .Assistant Secreturi/ of the Province.11415 2727-05 Giltuur Corporation Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Monique Robitaille, secretary, fille majeure, 3620 Fulluni, Apt.31, Montreal, Pierrette Baril, secretary, wife contractually separate as to property of Pierre Baril, 1820 De Loriinicr, Montreal, and Guy Yaliquette, chartered accountant, 2000 Régence, St-Bruno-dc-Montarville, for the following purposes: To carry on research, studies and experiments in the field of space, ballistics and explosives, under the name of \"Giltaur Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 18,000 Common shares of $10 each ami 4,(MM) preferred shares of $5 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(Jiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 7th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2675-65 Global Credit Corporation Corporation de crédit Global Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Volker Mehnert, notary, 6 Park Place, Apt.12A, West-mout, Herbert Klingner, accountant, 3955 Dupuis Avenue, Montreal, and Soja Andrejews, office clerk, wife separate as to property of Willy Berg, 211 Tall wood Place, Rosemère, for the following purposes: To carry on the business of a finance company, under the name of \"Global Credit Corporation \u2014 Corporation de crédit Global\", with a capital stock divided into 25,000 common shares without par value ami 500 preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company will be at 1155 Dorchester Boulevard West, Suite 1014, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rd day of June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 2530-65 Gulfstrenm «& Caribbean Realty Co.Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of June, 1965, have 3844 GAZETTE OFFICIEL II DE QUÉBEC, 11 juillet 1865, 97' année, No province de Québec, des lettres patentes, en date d'il 3e jour de juin 1965, constituant en corpo.ration: Donald Kujan, avocat, 3480 chemin Cote-de-Liesse, Muni Royal, Raymond Cart-aright, avocat, 71.chemin Devoni Bnie-d'Urfé, l.aua Switser, 1665, avenue Carlton, Montréal, et Micheline Bertrand.2162, rue Sherbrooke ouest, Mont irai, ces deux dernières secrétaires, filles majeures et usant de leurs droits, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'une compagnie d'immeubles h de construction, sous le nom de « G h If.stream Ik Caribbean Realty Co.Ltd.avec un capital total de 840,000, divisé en 25,000 actions ordinaires de 81 chacune el 1,500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnies sera 620, rue Victoria, Montréal, district judiciaire de Monica I.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 3e jour de juin 1065.Le Sous-secrétaire de la province, R \\ vmon d douville.11415 2623-65 \u2022 Help a Stranger Inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant -gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de juin 1065, constituant en corporation sans capital-actions: Thomas Wilson Dcachinan.administrateur, Marguerite Catherine I.iddle.ménagère, épouse séparée de biens dudit Thomas Wilson Dcaehmnn.tous deux de 275, Belair est.Rosemère, el Caryl Mac Donald, secrétaire, veuve de Robert Joseph Garden, 3467, rue Peel, app.3, Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir la célébration d'un Noel plus charitable, sous le nom de - Help a Stranger Inc.Le montant auquel sont limités les biens immobiliers (pic |a corporation peut posséder, est de 8100,000.I.e siège social de la corporation sera 1500, rue Stanley.Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce se jour de juin 1965././\u2022 Sous-sccri taire de la province, Raymond Douvillk.11415 2674-65 Hôtel fies Mille Iles inc.Avis est donné- qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 9e jour de juin 1965, constituant en corpora-tion: Rosaire Cliarhomicuu.marchand, Alice Corbeil ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Rosaire Charbonneau, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux de 00.St-Louis, Terrelamne, et Richard Charbonneau, marchand, 58, St-Louis.Terre-bonne, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, sous le nom de « Hôtel des Mille lies Inc.avec un capital total he $100,000, divisé en 7.500 actions ordinaires de $10 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Ia' siège social de la compagnie sera à Terre-bonne, district juduciaire de Terrebonne.been issued by the Lieutenant-Governor of tlic Province of Quebec, incorporating! Donald Ku jail, advocate.3480 Côte de-Licssc Road.Mounl Royal.Raymond ( artw right, advocate, 71 Devon Road.Uaic-dT'rfé.Lana Switzcr.4665 Carlton Avenue, Montreal, and Micheline Bertrand, 2162 Sherbrooke Street West.Montreal, the latter two secretaries, filles majeures ci usant de leurs droits, for the following purposes: To carry on the business of a real (slide an I const ruction company, under the name of '*( lull i ream & Caribbean Really Co.Ltd.\", with i total capital slock of 840,000, divided into 25,000 common shares of $1 each ami 1.500 preferred preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e al 020 Victoria Street, Montreal, judicial district of Mont real.(iiven al the oflice of the Provincial Secretary, this 3rd day of June, 1065.If \\YMo\\n Dot ville, , Assistant Secretary of the Province.11415-0 2623-65 Help a Stranger Inc.Notice is hereby given that under Pari III ol the Quebec Companies Act, letters patent.bearing date the 8th day of .lune.1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, t incorporate as a corporation without share capital: Thomas Wilson Deacliman, executive.Marguerite Catherin.Lidclle.housewife, wife separate a- lo property of the said Thomas Wilson Dcachiuan, ImiIIi ol 275 Belair Last, Rosemère.and ( 'a: y i Mac] >omild.secretary, widow of Robert Joseph Garden, 3467 Peel Street.Apt., \u2022>.Montreal, for the following purposes: To promote the celebration of a mora chari table Christmas, under the name of \"Help i Stranger Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may own or hold, is to be limited, is $100,000.The head oflice of the corporation will be al 1500 Stanley Street, Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 8Ul clay of .lune.1965.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.lilt .\">- 2674-65 Hôtel des Mille Iles inc.Notice is hereby given lh.it under Part I of the Quebec Companies .Vet.letters patent, bearing dale the 9th of June.1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Rosaire Char- bgnneau.mere-haul, Alice Corbeil, housewife, wife contractually separate as to property of tin-said Rosaire Charbonneau, and duly authorized by him for these presents, both of 00 St-Louis, Terrebonne, and Richard Charbonneau, merchant, 68 St-Louis, Terrebonne, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers, under the name of \" Hôtel des Mille Iles Inc.\", with u total capital stock of $100,000, divided into 7,500 common shares of $10 each and 250 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company will l)c at Terrebonne, judicial district of Terrebonne, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1965, Vol.97, No.29 3845 Donné un bureau «lu secrétaire de la province, ce 00 j«>ur de juin 1905.Le Bout secrétaire Je lu province, Raymond Douvillk.UII5-0 2718-65 Immeuble* Verdon liée Avis est donné qu'en vertu de la première pailie de la Loi des compagnies de Québec, il u été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, det lettres patentes, eu date du le jour de juin 1905, constituant en corporal ion: Benoit Rclleau, comptable! 2060, boulevard Pèrc-Lélièvre, I,es Saules, Benoît Dorval, comptable, 241.1ère Avenue, Orsainville, et Adrien Lacliance, comptable, Mil, Bougainville, Québec, pour les objets suivants: Faire all'aires connue agents d'immeuble, sous le nom de « Immeubles Verdon liée », avec un capital total de 860,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale «le 610 chacune el en 2.000 actions privilégiées d'une valeur nominale «le $10 chacune.\\jc siège social «le la compagnie sera 480, nie Caron, Québec, district juducuure «le Québec.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce le jour «le juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11416-0 2100-05 Industrial Marking Systems Inc.Systèmes de marquage industriel inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du 7e jour «le juin 1905, constituant en cor-poration: Cilles Haillargeon, commerçant, Solange Brien, ménagère, épouse séparée «le biens dudit (iilles Baillargeon, tous «leux de 4SS7, rue Gignac, St-Vincent -dc-Paul, et Richard Sam-son, avocat, 5587, rue des Tulipes, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Adresser, faire les dessins et/ou les impressions sur toutes sortes d'étiquettes destinées à la livraison «le colis de tous genres, sous le nom «le ¦ Industrial Marking Systems Inc.\u2014 Systèmes de marquage industriel inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 3310, rue Monselet, Montréal-Nord, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 7e jour «le juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-o 2484-05 Les Industries Laliberté ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 2e j«nir de juin 1905, constituant en corporation: Raymond Laliberté, Pierre-Paul Lali-berté, aviculteurs, «le Honfleur, et Maurice Bouchard, comptable, St-Georges, pour les objets suivants: Faire affaires comme aviculteurs et faire le commerce de cages en métal et autres produits du genre se rapportant au commerce de l'avi- Given at the ollice of the Provincial Secretary, this 9th day of June, 1905.Raymond Douvillb, Assistant Secretary of the Province.11415 2718-65 Immeubles Verdon ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, I tearing «late the 4th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incor]>orating: Benoît Belleau.accountant.2900 Père-I/dièvre Boulevard, les Saules, Benoît Dorval, accountant, 241, 1st Avenue, Orsainville.anil Adrien Lacliance, accountant, 864 Bougainville, Quebec, for the foloowiug purposes: To carry on business as real estate agents, under the name of \" Immeubles Verdon ltée\", with a total capital stock of $00.000, divided into 4.0(H) common shares of a nominal value of $10 each, and into 2,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head ollice of the icompany will be at 480 Caron Street, Quebec, judicial district of Quebec.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 4th day of June, 1905.Raymond Douvillb, Assistant Secreatartj of the Province.11415 2400-05 Industrial Marking Systems Inc.Systèmes de marquage industriel inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gilles Baillargeon, trader, Solange Brien, housewife, wife separate as to property of the said Cailles Baillargeon, both of 4887 Gignac Street, St-Vincent-de-Paul, and Richard Samson, lawyer, 5587 des Tulipes Street, Montreal North, for the following purposes: To address, make the drawings anuverneur «le lu province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 2e jour «le juin 1903, constituant en corporation: Pierre udonde, avocat, 10120, Grande-Allée, Montréal.Hervé Bélanger, avocat, 230, rue Floury, ait, Montréal, el Françoise Dumais, secrétaire, tille majeure et usant «le ses droits, 100251!, rue Fsplanade, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs et exercer les activités d'entrepreneurs et de conseillers en publicité, sous le DOn «le * Leroux & sssociés limitée >', avec un capital total «le $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale «le $10 chacune et an 2,000 actions privilégiées «l'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera suite 205, 3400, boulevard Métropolitain, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 2c jour «le juin 1905.Le Sous-sccrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2350-05 La Ligue des propriétaires et des contribuables de Stc-Marguerite inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été acoOrdé, par le lieutenaiit-g«>uverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late «lu 2e jour «le juin 1905, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques Viau, avocat, 334, 43e Avenue.Lachine, Pierre Viau, avocat, 11370, Bruxelles, Montréal-Nord, et Renée Auger, secrétaire, fille majeure, 534, Trudeau, La-Salle, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts culturels et sociaux des membres «le la corporation, sous le nom «le « La Ligue «les propriétaires et des contribuables de Ste-Margueritc inc.».Le montant au«piel sont limités les biens immobiliers «pie la corporation peut acquérir et posséder, est de $50,000.Le siège social de la corporation sera à Ste-Margucritc-du-Lac-Masson, dictrict judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 2e jour de juin 1905.Le Sous-secrêtaire île la province, Raymond Douville.11415-0 2518-65 Linton Radiologists Inc.Avis est donné qu'en bertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en «late du 7e jour de mai 1905, constituant en corporation: Clifford George Meek, comptable, 3101, avenue Maplewood, Colin Richard Chisholm, commis, 2534, boulevard Pie IX, tous «leux de Montréal, et Theodore William Martinson, commis, 4217, avenue Western, Westmount, pour les objets suivants: Établir, exploiter et diriger un ou deux bureaux médicaux et centres de radiologie, sous le nom de « Linton Radiologists Inc.», avec un capital total de $40,000, divise en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur uu pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnies sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.bearing «late the 2nd «lay of June, 1905, have been issue«l by the Lieutenant-Governor of tin Province of Quebec, incorporating : Pierre L londc, advocate, 10120 Grande-Allée, Montreal.Hervé Bélanger, advocate, 230 Fleury St.I'., Montreal, and Françoise Dumais, secretary, spinster of the full age «»f majority in use «>f In rights, 100251! Fsplanade St., Montreal, for the following purposes: To curry on business as printers and to act a publicity contractors and advisers, under thi name of \"Iatoux & associés limitée\", with a total capital stock of 640,000, divided into 2,00 common shares of u nominal vulue of $10 aacl ami 2,000 preferred ¦hares of a nominal value \u2022> $10 each.The head office of the company will be in suite 205, 3400 Metropolitan Blvd., Montreal judicial district «>f Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 2nd «lay of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi, of the Province.11415 2350-0 La Ligue des propriétaires et des contribuables de Stc-Marguerite inc.Notice is hereby given that under Part III «> the Quebec Companies Act, letters patent bearing «late the 2nd f June, 1066, hav< been issued by the Lieutenaut-tiovernor «>f tin Province of Quebec, to incorporate as a c«np ration without share capital: Jacques Viau, ad vocate, 334, 43rd Ave., Lachine, Pierre Viau, advocate, 1 1370 Bruxelles, Montreal-North, and Renée Auger, secretary, spinster of the full agi of majority, 534 Trudeau, LaSalle, for the following purposes: To promote the cultural ami social interests of the members of the corporation, under tin name of \"La Ligue des propriétaires et des contribuables de Ste-Marguerite inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold is to be be limited, is $50,000.The head oflice of the corporation will he at Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, judicial district of Terrebonne.(Jiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2518-05 Linton Radiologists Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 7th «lay of May, 19G5, have been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province of Queliee, incorporating: Clifford George Meek, accountant, 3101 Maplewood Avenue, Colin Richard Chisholn, clerk, 2534 Pic IX Boulevard, both of Montreal, ami Theodora William Martinson, clerk, 4217 Western Avenue, Westmount, for the following purposes: To establish, operate and manage one or more medical offices and radiology centers, under the name of \"Linton Radiologists Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 c«>m-iiion shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1965, Vol.97, No.29 3849 Donné uu bureau du secrétaire de la province, ce 7e jour de mai 1905.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.U1I5 2138-65 Maçonnerie Moderne liée Modem Masonry Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, il a ! té accordé) par le lieiitenant-g«>uverneur «le la province «1«' Québec, des lettres patentes, en date du 1er jour lie juin 1905, constituant en corporation: Albert Poirier, estimateur, 447, Bt-Jean, Longucuil, Guy Lanicl, comptable agréé, et Vvon Goulet, avocat, ces deux «lerniers de 10339, Si Laurent, Montréal, pour les objets suivants: Exécuter d'une façon générale les travaux de maçonnerie, sous le nom «le « Maçonnerie Moderne ltée \u2014 Mo«lern Mastmry Ltd.», avec un capital total «le 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 300 .m I inns privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Lon-gueuil, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 1er jour de juin 1905.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.L 141(6-0 2018-05 Maison Aliscan (1965) inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a té accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en date du L8e jour «le mai 1905, constituant en corporation sans capital-actions: Reginald Boisvert, écrivain, 3225, Ridgewood, Montréal, Jean Morin, conseiller en taxation, 5235, rue Fabre, Montréal, Bruno Gagnon, inspecteur, 1335, Bernard, ouest, Outremont, S.J.Kearney, agent «le manufacturiers, 1335, Bernard, ouest, Outremont, Gérald Payette, gérant «le ventes, 5645, 17e avenue, Montréal, Maurice Rivard, niaitre «le postes, et Ed.Sullivan, gérant, ces deux derniers de Val-Davi«l, pour les objets suivants: Exploiter «les maisons de réhabilitation pour alcooliques, autres que des hôpitaux, sous le nom de « Maison Aliscan (1905) Inc.».Le montant auquel sont limités les biens im-mohiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est «le $100,000.Le siège social de la corporation sera à Val-David, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 18e jour «le mai 1905.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.11415-0 1747-05 Bruce Malien & Associât- * \"ne.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 8e jour de juin 1905, constituant en corporation: Rollin Gallay, avocat, 0190, chemin Hudson, Montréal, Joel A.Pihsky, avocat, 4597, avenue Oxford, Montréal, et Isabelle Nicholson, secrétaire, célibataire, 3601, Ste-Famille, Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de consultants en administration, sous le nom de « Bruce Malien & (iiven at the ollice of the Provincial Secretarv, this 7th «lay of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi/ of the Province.11415-0 8138-65 Maçonnerie Moderne ltée Modern Masonry Ltd.Notice is hereby given that under l'art I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st «lay «>f June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Albert Peltier, estimator, 447 St-Jcan, Longucuil, Guy Lanicl, chartered accountant, and Vvon Goulet, lawyer, the latter two of 10339 St-Liuireiit.Montreal, for the following purposes: To execute in a general way masonry work, under the name of \" Maçonnerie Moderne ltée \u2014 Modern Masonry ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company will be at Longucuil, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2018-05 Maison Aliscan (1965) inc.Notice is hereby given that under Part III of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 18th «lay of May, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to incorporate as a corporation without share capital: Reginald Boisvert, writer, 3225 Ridgewood, Montreal, Jean Morin, tax counsellor, 5235 Fabre Street, Montreal, Bruno Gagnon, inspector, 1335 Bernard West, Outremont, S.J.Kearney, manufacturing agent, 1335 Bernard West, Outremont, Gérald Payette, sales manager, 5045.17th Avenue, Montreal, Maurice Rivard, postmaster, and Ed.Sullivan, manager, the latter two of Val-David, for the following purposes: To operate rehabilitation homes for alcoholics, other than hospitals, under the name of \" Maison Aliscan (1905) Inc.\", The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000.The head office of the coproratiou will be at Val-David, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary, this 18th day of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 1747-05 Bruce Malien & Associates Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quel>ec, incorporating: Rollin Gallay, advocate, 0190 Hudson Road, Montreal, Joel A.Pinsky, advocate, 4597 Oxford Avenue, Montreal, and Isabelle Nicholson, secretary, spinster, 3001 Ste-Famille, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of management consultants, under the name of \" Bruce Malien GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet I9H5, 97' année, No 29 3850 Associates Inc.», avec un capital total rdé.par le lieutenant-gouverneur de la province de Quél>ec.des lettres patentes, en date du 10e jour de mai 1005, constituant en corporation: Richard La Charité, avocat, Claudette Hoily, ménagère, épouse séparée de hiem dudit Richard La Charité, tous deux de 2.2c avenue, Ste-Marthe-sur-le-Lac, et Marguerite Houle, secrétaire, veuve d'Aldéric Trudelle, 170, rue Les Saules, St-Kustachc, pour les objets suivants: Faire affaire! comme épiciers-bouchers et comme marchand de fruits et légumes, sous le nom de « Marché J.P.St-Charles ltée J.F.St-Charles Market Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $50 chacune et en 600 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie sera 1705, chemin Oka, Deux-Montagnes, district judiciaire de Terrebonne.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 19e jour de mai 1905.[je Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.11415-0 2335-05 Massicoltc transport inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première parrie «le la Iah «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en date «lu 10e jour «le juin 1965, constituant en corporation: Linilien Vallée, avocat, 168, Ile de France.Longucuil.Adrienne St-Hilaire.secrétaire, veuve, 0825, boulevard Pie IX, app.0, Montréal, et Madeleine Normandeau, secrétaire, fille majeure usant de ses «Iroits, 6020, Iberville, Mont-tréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «le transport, sous le nom «le « M&ssicotjte transport im .avec un capital total «le 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 3463, rue St-Denis, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 10e jour «le juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2004-05 Milnisoii Investment Corp.Avis est donné qu'en vertu ce la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 28e jour de mai 1905, constituant, en corpo- & Associates [ne.\".with a total capital stock of $10,(100, divuled into 500 common shares ol $10 each and 350 preferred shares «)f $100 each.The head oflice «>f the company will be a 1390 Sherbrooke Si reel West, Apt.36A, Montreal, judicial district of Montreal.(îiven at the office of the Provincial Secretary, this 8th day of June, 1005.Raymond Dou villi., Assistant Secreturi/ of the Province.11416-0 2695-65 Marché J.P.St-Charles lice J, I*.St-Charles Market Ltd.Notice is hereby given that under Fart I ol the Quebec Companies Act.letters patent, bearing date the 19th day of May, 1005, hav.been Issued by the Lieutenant-Governor «>f th< Province «>f Quebec, incorporating: Ri«diar«l La Charité, lawyer.Claudette Roily, housewife wife séparât»' as to property of the said Richard La Charité, hot h of 2.2nd Avenue.Ste Marthe-sur-lc-Laf the full age «>f majority in use t>f her rights, 6020 Iberville, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \" Massicotte transport inc.\".with a total capital stock t>f $40,000, «livided into 100 common shares «>f $100 each and 300 prefcrml shares of 8KM) each.The head office of the company will be at 3453 St.Denis St., Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assiatant Secreturi/ of the Province.11415 2664-65 Milnison Investment Corp.Notice is hereby given that under Part.I «>f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th «lay of May, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Allan Avrith, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1905, Vol.97, No.29 3851 ration: Allan Abrith, agent, 2150, chemin Athlo- ne Mont Royal, Anna Stcdinau, secrétaire, célibataire, 2415, chemin Sundet, Mont Royal, el Seymour Avrith, avocat, 0275, Place North-c est, Montréal, pour 1rs objets luivants: Exercer !«\u2022 oommerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Milnison [nvest- nient Corp.», avec un capital total de 8250,000, .1 i \\ en 100,000 allions ordinaires d'une valeur au pair «le 81 chacune et 15.0(H) actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.l,c siège social «le la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce I Be j'>ur de mai 1066, Le Sous-secrétuire de lf an investment company, under the name of \" Milnison Investment Corp.\", with a total capital stock of 6250,000, divided into 100.0(H) common shares of a par value «»f 81 each and 15,000 preferred shares «>f a par value of 810 each.The head oflice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office «>f the Provincial Secretary, this 28th day of May, 1065.Raymond Dot vii.i.k, Assistant Secretary f the Province.11415-0 2553415 Mio Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of May.1905, have been issued by the Licutcnant-(iovernor of the Province f Quebec, incoiporating: Laiser Sirota, advocate, Miriam Bernard, secretary, fille majeure, and Rayroonde Lauze.receptionist, fille majeure, all three of 210 St.James Street West, Montreal, for the following purposes: To operate a dress shop or shops, under the name of \"Mio Limited\", with a total capital stock of $10,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 3.5(H) preferred shares of $10 each.The head office of the company will be at (5222 Monk Boulcvurd, Montreal, jiulicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 28th day of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-o \u2022 2555-05 Montreal Express Service Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, lettres patent, bearing «late the 10th «lay of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-(iovernor of the Province of Quebec, incorporating: A«lrien-R.Paquette, 212 Bloomfield, Outremont, Fernand SimanL 200 St.James, West, suite 1010, Montreal and Marcel Paquette.-1320 Chanteclcrc, St-I!runo-de-Montarvillc, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Montreal Express Service Inc.\", with a total capital- st«x-k of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 350 prcferreil shares of $100 each.The head ollice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2037-05 M ult iconi Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of May, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Lambert GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet 1905, 97' année, No 29 3852 ration: Lambert Toupiii.avocat, 227, I.ockliart, Mont-Royal, Bertrand Lacombc, avocat, 8200, avenue Ridgewood, Montréal, el Michel Gagnon, avocat, 3175, avenue N'emlônie, Montréal, pour les objet! suivants: Paire affairai connue imprimeur! el éditeur!, sous le nom de « Multicôm Inc.avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie mm Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secretaire de la province, ce 31e jour de mai 1966, Le Sous-seen 'taire tie la jirorince, Raymond Doi villi:.11415-u 21:17-05 North Shore Truck è% Equipment Ltd.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 3e jour de juin 1086, constituant en corporation: Pierre La Rue, avocat, 3031, de la Retraite, Ste-Foy, Jacques Déliais, avocat, 1240, de Samoa, Sillery, et .lean Poudrier, étudiant, 702, St-Cyrille, ouest, Quél>cc, pour les objets suivants: Faire le commerce de vcniciilcs automobiles et faire affaire! comme garagistes, sous le nom de « North Shore Truck & Equipment Ltd., avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale «le $100 chacune.Ix?siège social «le lu compagnie sera Kit), rue N«)ël, Sept-Iles, district judiciaire de Haute-rive.Donné au bureau «lu secretaire «le la province, ce 3e jour «le juin 1065.Le Sous-seerétaire tic la prorince, Raymond Doi villk.11415-0 2027-05 Ontario Cuvillicr Car Wash Inc.Avis est donné qu'en vertu de la premier»' partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late du 2e jour de juin 1905, constituant en corporation: Claude Breault, commerçant, 1832, Bourhonnière, Montréal, Y von Brault, ferblantier, 101A, rue du Parc.Laval-«les-Rapi«les, Micheline Landry, ménagère, épouse contract uellc-ment séparée de biens «le Pierre Lemire, 3303, rue Bélair, St-Michel, et Denise Landry, ménagère, épouse contractuellement séparée «le biens d'Orner Lamoureux, 489, chemin de la Loraine, Fabreville, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes, sous le nom de « Ontario Cuvillier Car Wash Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 2e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-o 2221-05 Paquette et Grenon (Québec) limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le lu province de Québec, des lettres patentes, en «late Toùpin, lawyer, 227 I.ockliart, Mount-Roya!, Bertrand Lacombc, lawyer, 3260 RidgOWOOtl Avenue, Montreal, and Michel Gagnon, lawyer.3475 Vendôme Avenue, Montreal, for the follow ing purpose!! To carry on business as printers and editor-.Under 111 «.- name of \"Mullicoin Inc.\", with a total capital stock of 840,000.«livideil into 1,000 common shares of $10 each.The head office «>f the company will Ik- al Montreal, juducial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this Slat «lay of May.1065.Raymond Doi villi:.Assistant Secretary of the Province.11115 2437-65 North Shore Truck A Equipment Ltd.Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, letters patent bearing dale the 3rd «lay of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Pierre LaRui lawyer, 3034 de la Retraite, Ste-Foy, Jacques Delude, lawyer.1240 «le Samoa, Sillery, and .ban Poudrier, student, 702 St-Cyrille West, Quebec, for the following purposes: To carry on business dealing in automobiles, and to act as garagemen, under the name ol \"North Shore Truck & E«piipment Lt«L\", with a capital slock divided into 1.000 common share-without nominal value and into 200 preferred shares «if a nominal value of 8100 ca«di.The head ollice of the c«>mpany will be at 400 Nog) Street, Sept-Iles, judicial district of Saute-rive.(îiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 3rd «lay of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province, 11415 2027-05 Ontario Cuvillier Car Wash Inc.Notice is hereby given that Under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2ml «lay of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of tin-Province of Quebec, incorporating: Claude Brcault, trader, 1832 Bourhonnière, Montreal.Yvon Brault, tinsmith, 101A «lu Parc Street, Laval-des-Rapidcs.Micheline Landry, housewife, wife contractually separate as to property of Pierre Lemire, 3303 Bélair Street, St-Michel.ami Denise Landry, lunisewife, wife contractually separate as to property of Outer Lamoureux, 489 de la Loraine Road, Fabreville, for the following purposes: To carry on business as garage keepers, under the name of \"Ontario Cuvillier Car Wash Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head ollice of the company will be at Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2221-05 Paquette et Grenon (Québec) limitée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th «lay of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, tM, Vol.97, No.29 8868 du LOe Jour da juin 1966, «'«instituant en eorpo- at ion: Ibdainl La traverse, gérant «le magasin, ! 1raiuville, Roinéo Puipicttc.J.-F.mile Grenon, marchands, et Laurier Trot lier, comptable, ces dernière de Lanier Lake, province d'Ontario, pour les objets suivants: l'aire all'aires connue épiciers-bouchers, sous le nom de « Paquette et Grenon (Québec) limi- .avec un capital total de $95.000, divisé en 50,000 actions ordinaires de SI chacune et BU l(! actions privilégiées «le $10 chacune.I.c >iègc sik'ial «le la compagnie sera à Yille-Marie, district judiciaire de Téini.scainisgue.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 10e jour de juin 1905.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.I Ulô-o 2740-05 i-ii-tim Perron «X Tils lt mes de chauffage, sous le nom «le « Gaston Perron & fils ltée », avec un cupital total «le M0.000, divisé en 2,000 actions ordinaires «le 1 > haeune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Jacques-1 artier, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 2e jour de juin 1065.Le Sous-secrétaire Je la province, Raymond Douvillk.11415-0 2000-05 Les Placements Cam pi inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ixri des compagnies «le Québec, il a te accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 2e jour de juin 1905, constituant en corpo-:;ilion: Gérard Yinet, « barman », 45, rue Léger, St-Timotliéc, Normand Ilochefort, briqueteur, 113, boulevard du Havre, S a 1 a be r r y - « 1 e - Yalley-field, et .lean Paiement, comptable, 48, rue Tully, >alahcrry-f the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 2nd «lay of -lune.1065, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: dean Belleau, lawyer, Claudette Pallass and Pauline (iohcil, secretaries, lilies majeures, all three of 585 ('barest Boulevard Bast, Quebec, for the following purposes: To carry on hu-iiu-\u2014 «lealing in all apparatus or heating systems, under the name of 1 Gaston Perron & fils ltée\", with a total capital stock of $10,000, divided into 2.000 common shares of $10 each and into 2.000 prefinvd shares of $10 each.The head office of the company will be at JacquesrCartier, judicial district of Montreal.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1965.Raymond Doi:villi:, Assistant Secretary of the Province.11415 860046 Les Placements Campi inc.N«)ticc is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of June.1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Gérard Yinet, \"barman\", 45 Léger Street, St-Timothée, Normand Bochefort, bricklayer, 113 du Havre Boulevard, Salaberry-ile-Yalleyficld, and .lean Paiment, accountant.4S Tully Street.Salaberry-«le-YalleyficId.for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Placements Campi inc.\", with a total capital stock of 810,000.divided into 1,000 common shares of $10 each ami into 3,000 preferred shares of 810 each.The head office «)f the company will be at Salaherry-dc-Yalleyfiehl, judicial district of Beau-harnois.Given at the office «»f the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2440-05 Placements Longsault inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 2Mb «lay of May, 1965, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporation: Simon Valois, 8854 GAZETTE OFF Kl ELLE DE QUÉBEC, 17 juillet mer,, 97' année.No 29 ration: Simon Valois, notaire, II'».BéVmrd, Ro« ger LaGarde, avocat, 189, Fraser, Guy LaGarde, courtier d'assurances, 666, Grftce, Dr Roger Tou-pin.médecin vétérinaire, nu-Taylor, Dr Charles Roy, chirurgien-dentiste, rue Stuart, Robert Le.gault, entrepreneur, chemin Brownsburg, Gaétan si -Jacques, industriel, 5o, Charles, Dr Marcel Sylvestre, médecin, tous huit de'Lachute, René Desormeaux, capitaine Doivii.i.i:.11416-0 2277-66 Placements Vidéo ltée Video Investments l.id.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a éu: accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du le jour de juin 1065, constituant en corporation: Hugo Bonin, commerçant, 10468, Place Prieur, Montréal, .Inde Barrette, Lorenzo Barrette, Jean Denis, tous trois industriels, .lean Bergeron, épicier, Dr Jacques Plourde, médecin, et Jean-Louis Rompre, comptable, ces six derniers de Marrante, pour les objets suivants; Paire affaires connue compagnie de placement, sous le nom de Placements Vidéo ltée Video Investments Ltd.avec un capital total de 8250,000, divisé en 50,000 actions ordinaires d'une valeur nominale SI chacune et en 20.000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnies géra à Barrante, district judiciaire d'Abitibi.Donne au bureau du secrétaire de la province, ce le jour de juin 1965.I.c Sous-secrêtaire de la province, R vymon d Doi vu.i.i.11415-0 2606-65 La Plomberie R.Légaré & fils liée R.Légaré & Sons IMiimbing l.id.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Québec, il a «'\u2022té accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, «-il date du 2e jour «le juin 1905, constituant en corporation: Roinéo Légaré, plombier, 9005, La-keunessc, Denise Sauvagcau.3432, boulevard Rosemont,et Hélène Lampron, «1455, «les Érables, ces doux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en plomberie, chauffage et en réfrugération, sous le nom «le « La Plomberie R.Légaré & fils ltée \u2014 R.Légaré & Sons Plumbing Ltd.avec un capital total de 860,000, divisé en 200 actions «>r«li- naires «le $5 chacune et en 4.900 actions privilégiées «le 610 chacune.Le siège social de la compagnie sera 8665, rue Lajeunesse, Montréal, district judiciaire «le Montreal.notary, iiô Bédard, Roger LaGarde, advocate, 180 Fraser, Guy LaGarde, insurance broker, 655 Grftce, Dr.Roger Toupin, veterinary doctoi Taylor St., Dr.Charles Roy, dental surgeon, Stuard St., Robert Legault, contractor, Brown, burg Road, Gaétan St-Jacques, industrialist.5(1 Charles, Dr.Marcel Sylvestre, physician, all eight of Lachute, René Desormeaux, ferry cap lain.Carillon, ami Levis Clément, accountant, Roy Ave., Ayeisville.for 11 ic- following purpose- To carry ou business as an investment com pauv.under the name of \"Placements Longsau inc., with a total capital stock of 6100,000 divided into in.nun common shares «>f a nominal value of si each ami each ami 9.000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head ollice of the company will be ai Lachute, judicial district of Terrebonne.Given at the office of the Provincial Secretary this 28th day of May.l'.n'.ô.U u\\u»ni> Douvillb, Assistant Secretary of thé Province.11415 \" .8877-65 Placements Vidéo ltée Video Investments Ltd.Notice is hereby given thai under Pari I of the Quebec Companies Act, letters patent', hearing date the 1th day «if June.1665, hav« been issued by the Lieutenant-Governor «»f the Province of Quebec, incorporating: Hugo Bonin, trader, 10468 Place Prieur.Montreal, Jude Bar rette, Lorenzo Barrette, Jean Denis, all three industrialists, Jean Bergeron, grocer, Dr.Jac ques Plourde, physician, and Jean-Louis Rom pré, accountant, these last six of Barrante, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Placements Vidéo ltée Video Investments Ltd.\", with a total capital s|of Abitibi.(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 1th day of June.1965.It wmon n Douvillb, Assistant Secretary of tin1 Province.11415 2000-f.:.Lu Plomberie R.Légaré f $50,000, divided into 200 common shares «)f $5 each and into 4,900 preferred shares «>f $10 each.The head office of the company will be at 8665 Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1905, Vol.97, No.29 3855 Donné au bureau «lu secrétaire «I** la province, ce _'«\u2022 jour de juin 1966.Lj Sous-secrétaire de la province, Raymond Doi vii.i.k.Mil.\")-.2598-05 Productions 8-16 inc.Avis eat donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettrés patentee, en date du 10e jour i «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes, en date du 1er jour «le juin 1966, constituant en corporation: Solomon Katz, notaire, 0201, C6te St-Luc, app.I, Hampstead, Harriet Gold, secrétaire, fille majeure.5500, avenue Snowdon, Penthouse 2, Montréal, et Joseph S.Kaplan, notaire.18, chemin Bclsize, Hampstead, pour les objets suivants: Exercer le commerce de quincaillerie, accessoires électriques, marchandises «le sport, machinerie et équipement «le toutes sortes, sous le nom de « Progressive Automotive Wholesalers Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires «le $10 chacune et 3,500 actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e 1er jour de juin 1005.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymon» Douvillk.11415 2308-05 Prole* (Quebec) Ltd.Prolew (Québec) ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies «le Quéoec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes, en date «lu 12e jour «le mai 1005, constituant en corporation: Richard J.F.Bowie, 1280.Ixmlevard Laird, Mont Royal, C.Stephen Cheasley, 7, avenue Rennie, Montréal Ouest, et Jacques Loranger, 235, avenue Kensington, Westmount, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer et exercer le commerce de machinerie industrielle, sous le nom de « Prolew (iiven at the office of the Provincial Secretary, this 2ml «lay of June, 1905.Raymond Doi;villi:, Assistant Secretary of tlir Province.11415 2898-68 Productions 8-16 inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day «>f June, 1965, bave been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province «»f Quebec, incorporating: René Leroux, notary, 6466 Duquette, Hubert Leroux, student, 4888 Coolbrook, Fugéiiie Vézina, secretary, wife separata as to property «>f Eugène Vézina.1708 St.Hubert, (îaëtane Charbonneau, secretary, wife separate as to property of Laurent Charbonneau, 3810 St.Catherine East, ami Solange Thibault, s«'«retary, fille majeure, 5945 Place «le MeaUX, all five «>f Montreal, for the following purposes: To operate television, radiodiffusion and radio transmitting ami receiving stations, under the name of ''Productions 8-10 inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of S10 each.The head office of the company will he at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th «lay «>f June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi, of the Province.11415 2491-05 Progressive Automotive Wholesalers Inc.Notice is hereby given that under Part 1 of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 1st day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Solomon Katz, notary, (5201 Côte-St-Luc Road.Apt.1, Hampstead, Harriet Gold, secretary, spinster «>f the full age of majority, 5500 Snowdon Avenue, Penthouse 2, Montreal, and Joseph S.Kaplan, notary, 18 Belsize Road, Hampstead, for the following purposes: To deul in hardware, electrical supplies, sporting goods, machinery and equipment of all kimls, under the name of \"Progressive Automotive Wholesalers Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares t>f $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company will l>e at Montreal, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 2308-05 Prolew (Quebec) Ltd.Prolew (Québec) ltée Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of May, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Richard J.F.Bowie, 1280 Laird Boulevard, Mount Royal, C.Stephen Cheasley, 7 Rennie Avenue, Montreal West, and Jacques Loranger, 235 Kensington Avenue, Westmount, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in industrial machinery, under the name of \"Prolew (Quebec) tfs50 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet 1965, 97' année.No 29 (Quebec) Ltd.\u2014 Prolew (Québec) ltée ».avec un capital actions divise en 10,.St-Louis, St-Joseph, district judiciaire «le St-Hyacintlic.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce I Be jour de mai 1965.I.c Soue-êecretaire de la province, Raymond Doi vii.i.i:.1I415-0 2227-65 J.A M.Racine limitée Avis est donne qu'en vertu «le la première partie at Montreal, judicial District of Montreal.Given at the ollice of the Provincial Secretary, this 12th day «>f May, 1965.Raymond Doi vii.i.i:.Assistant Secreturi/ of the Province.11115-0 2070-';:, K.P.M.garage (St-Hyacinths) inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters paten bearing «late the 1Mb day of May, I'll).\"), hah.been issued by the Lieutenant-Governor «»f tin Province of Quebec, incorporating: Francesco Falconi, mechanic, 2690 Desaulniers, Claud Lussier, draughtsman, 2025 Beauparlaat, an! Jacques (iagiion, appraiser, 3100 Sicotte, al three of St.Hyacinthe, for the following pur- poses; To carry on business ilcahng in motor veliich and to act as garagi'im-n, under the name ol \"R.P.M.garage (St-Hyacinthe| Inc.\", with i total capital stock of 640,000, divided into W common shares of S100 each.The head office «»f the company will be at 80 St-Louis, St-Joseph, judicial district of St.Hyacinthe.Given at the office of the Provincial Secretary, this ISth «lay of May, 1985.Raymond Doi vii.i.k, Assistant Seen tun, of the Prorince.U415 2227-l J.«X M.Racine limitée Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, letters patent.bearing date the 2ml day of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Guy Racine, hardware dealer, 1935 Place Laurence, Jacques Racine, gentleman.014.00th Avenue, both of Chomedey, and Michel Racine, gentleman, 35 Labelle St., [*vsJ-de*-Rspidës, for the following purposes: To carry on business as grocers, under tin* name of \"J.& M.Racine limitée\", with a total capita] stock «>f 640,000, divided into 2,000 common shares of $10 each ami 200 preferreil shares of $100 each.The bead office «>f the company will be at 200 Crémasie Boulevard Fast, Montreal, judicial «listiict of Montreal.Given at the ollice «>f the Provincial Secretary, this 2nd day of June, 1005.Raymon d 1 >Of vi LLC, Assistant Secretary of the Province.11415 2541-05 Regency Upholstering Ltd.Rembourrage Régence lté* Notice is hereby given that under Part I of the .Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Harry Greenfield, executive, Elly Greenfield, housewife, wife separate as to property of the said Harry Greeu-field, both of 5770 Trinity Street, Côte-St-Luc, and Constantin Tsitiritlcs, executive, 8455 L'Acadie Bouleveard, Montreal, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1966, Vol.97, No.29 IXciver 1c commerce «le meubles, meubles lembouréset nouveuutés, sous l«- nom «le « Regen- cy Upholstering Ltd.- Rembourrage Régence ltée k, avec un capital total «le 940,000) divisé en 100 ICtioni ordinaires «l'une val«-ur au pair de $100 cluieunc et 800 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le 8100 chacune.I.t siège social «le la compagnie sera 55, avenue des Tins est, Montréal, district judiciaire «le i mtival.Donné au bureau du secrétaire «le la province, 1er jour «le juin l'.Miô.It Sous-secrétaire de lu province, R a ym«>n d I >ol ville.11416 2878-65 Rive Sud typo service Inc.Avis est donné Qtl*en vertu «le la premier»- partis «le la Loi des compagnies de Québec, il a .té accordée par le UeutenaniVgouverneur «le la ovince de Québec, des lettres patentes, en date du -le jour «le juin 1066, constituant en corporation! (haies J.(iélinas, avocat, 515, rue ( hain- pagneur, Outremont, Pierre Bourque, avocat, |s, rue Charles, I>«)llard-des-()rmeaux, et Finnois Bélanger, avocat, 14, rue Anselme*Lavigne, i ).illard-des-()rineaux, pour les objets suivants: l'.xcrcer la composition typographupie à l'UBS-\u2022 des imprimeries, sous le nom «le « Rive Sud typo service inc.», avec un capital t«)tal «le So0,0tM), divisé en 400 actions ordinaires «le 8100 i hacune et en 200 actions privilégiées «1«- 8100 scune.Le siège social «le la ciunpagnic sera à Boii- >i ville, district judiciaire «le Montr«:al.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 4e jour de juin 1966.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvilles.11415-0 2544-05 Riviera Manufacturing Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, des lettres patentes, en «late lu 8e jour «le juin 1905, constituant en corporation: Ann E.Clark, 3-155, Durocher, Montréal, Shirley Zinman, 4875, Bourret, Montr«'-al, toutes deux secrétaires, filles majeures, et Helen Lennon, ménagère, épouse séparée «le biens de Bernard Lennon, 718, Allion, LaSalle, pour les objets juivants: Manufacturer et exercer le commerce «le toutes sortes île produits, articles et marchandise, sous le nom «le « Riviera Manufacturing Ltd.», avec un capital t«>tul «le S40.000, «livisé en 2,000 actions ordinaires «l'une valeur au pair de 81 chacune et 3,800 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie sera 55, avenue des Pins est, Montréal, district judiciaire \u2022 le Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, «\u2022e 3e jour de juin 1905.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.U415 2624-05 Rollin limitée Roi lin Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en «late 3S57 To deal in furniture, upholstered furniture ami novelties, under the name of \"Regency Ipholsteriiig Ltd.\u2014 Rembourrage Régence ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 Common shares of a par value ol 6100 each and 800 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office f \"Rive Sud typo service inc.\", with a total capital stock «)f 800,000, divided into 400 «-«>inmon shares of 8100 each ami 200 preferred shares of 8100 each.The head oflice of the company will be at Rouehcrville, judicial district of Montreal.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of June, 1965.\u2022 Raymond Douvillk, Assistant Stcretan/ of the Province.11415 2544-05 Riviera Manufacturing Ltd* Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-(Iovernor of the Province of Quebec, incorporating: Ann E.Clark, 3455 Durocher, Montreal, Shirley Zinman, 4875 Bourret, Montreal, both secretaries, filles majeures, and Helen Lennon, housewife, wife separate as to property of Bernard Lennon.718 Allion, LaSalle, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Riviera Manufacturing Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,(KK) common shares of a par value «>f SI each ami 3,800 prcrerred shares of a par value of 810 each.The hca«l offi«-e of the company will be at 55 Pine Avenue East, Montreal, judicial district of Montreal.Given at the office of the Provincial Secretary, this 3rtl «lay of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-o 2024-05 Rollin limitée Rollin Limited Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th «lay of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the 3s5s GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet 190Ô, 97' année.No 29 «lu 8e jour de juin 11)05, const it «unit en corporation: Roger RoUln, commerçant, Rose-Mai Morrisscttc, ménagère, épouse commune en biens dudit Roger Rollin, et Bernard Dagenais, avocat, tous trois de Gatineaii, pour les objets suivants: Faire Affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Rollin limitée Rollin Limited ».avec un capital total de 840,000, divisé «'il 20,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 2.(XK) actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à (iatineau, district judiciaire de Hull.Donné au bureau du secrétaire de la province.ce Be jour de juin L066.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 2344-05 Komuuld construction ltée Avis est donné «pieu vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, des lettres patentes, en date du 7e jour de juin 1005, constituant en corporation: (lande Girard, industriel, 3100, Croissant de Paris, Duvernay, Romuald St-Laurent, menuisier, 302, 10e rue, Deux-Montagnes, et Fernand Girard, gérant «le magasin, 6330, St- Denis, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et «le construction, sous le nom «le « Romuald construction ltée*, avec un capital total «le 8100,000, divisé en 2,000 actions onlinaires de 810 chacune et en s.OOO aidions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social de la compagnie sera à Chomedey, district judiciaire de Montréal.Donné au bureau «lu secrétaire de la province, ce 7c jour «le juin 1066.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-o 2678-65 Paul-Émilc Roy inc.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie «le la \\x>\\ des compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur «le la province «le Québec, «les lettres patentes, en «late du 10e jour «le juin 1965, constituant en cor-poration: Paul-Emile Roy, agent manufacturier, Claudia Lap«>inte, ménagère, épouse commune en biens «ludit Paul-Emile Roy, et .lean-nine Roy, secrétaire, tous trois «le 275, rue La-vallée, Granby, pour les objets suivants: Manufacturer, réparer et faire le commerce d'appareils et machineries à l'usage des houlan-geries, sous h) nom «le « Paul-Emile Roy inc.», avec un capital total «le 8100,000, divisé en 1,000 actions onlinaires «le 810 chacune et en 0,000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie sera à Granby, district judiciaire «le Bedford.Donné au bureau du secrétaire «le la province, ce 10e jour de juin 1005.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doi:vii.i.k.11415-o 2704-65 Ste.Adèle Golf and Country Club Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies «le Québec, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la drovince de Québec, des lettres patentes, en date Province of Quebec, Incorporating: Roger Rollin, trader, Rose-Mai Morrissette, housewife, wife common as to property «>f the said Roger Rollin, and Bernard Dagenais, lawyer, all three of Gati.neaU, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of Rollin limitée - Rollin Limited'', with a total capital stock «»f 840,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and into 2,000 prcfcrretl shares «>f 810 each* v The hca«l ollice «>f the company will be at (iatineau, judicial district «>f Hull.(iiven at the ollice «>f the Provincial S«-«r«-tar .this 8th «lay of June.1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2844-65 Romuald construction liée Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 7th day of June.1005, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, incorporating: Claude Girard, industrialist, 3190 Croissant «!«¦ Paris, Du vernay, Romuald Si-Laurent, joiner, 302.L0t.li St., Two-Mountains, and Fernand Girard, store manager.0330 St.Denis Montreal, for the folio wing purposes: To carry on business as a real estate and con (ruction company, under the name of \"Roinua construction ltée\", with a total capital stock ol 8100,000, divided into 2,000 common shares .810 each and 8,000 preferred shares of 810 each, The head office of the company will l»e al Chomedey, judicial district of Montreal.(iiven at the ollice of the Provincial Secretary, this 7th «lay of June.1965.Raymond Doi villi:.Assistant Secreturi/ of the Province.11415 207 vi, Paul-Emile Roy inc.Notice is hereby given that under Part I ol the Quebec Companies Act, letters patent, liearing «late the 10th «lay «>f June, 1005.have lx*cn issued by the Lieutenant-(iovernor of th< Provines of Quebec, incorporating: Paul-EmiK Roy, manufacturing agent, Claudia Lapoinle.housewife, wife common as U> property «>f tin said Paul-Emile R«>y, and Jeauniue Roy, seen tary, all three of 275 Lavalh'-e St.Granby, for the following purposes' To manufacture, repair ami «leal in apparatus ami machinery Used in bakeries, under the name of \"Paul-Emile R«>y inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 0.000 preferred slum's of 810 each.The heatl ollice of the company will be at Granby, judicial district f Bedford* (Jiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 1005.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi/ of the Province.11415 2704-66 Ste.Adèle Golf and Country Club Inc.Notice is hereby given that under Part 1 ol the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of May, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the qiJKIIIK' OFFICIAL GAZETTE, July 17, 10(10, Vol.97, So.29 .In 31c jour «le mai 1 *!f the immoveable property which the corporation may hold is to be limited', is 8100,000.The head office Of\" the corporation will he al Montreal, judicial «listriet of Montreal, (liven ut the office «>f the Provincial Secretary.this 3rd «lay of June, f905.Raymond Douvii.i.k, Assistant Secreturi/ of the Province.11415 2029-05 Sol-Murk Printing Ltd.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of June, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Max S.Kaufman, advocate and Queen's Counsel.574 Claremont Avenue, Westmount, J.Roy Hoffman, a«lvoeate ami Queen's Counsel, 19IS May-fair Street, Montreal, and Sydney IL S«'derolf, advocate, 80 Crestwtuxl Avenue, Montreal West, for the following purposes: To carry on business as printers, under the name of \"S«>l-Mark Printing Ltd.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 200 common shares of 8100 each ami 200 preferre«l shares of 8100 each.The head office of the company will be at Montreal, judicial «listriet of Montreal.Given at the ollice of the Provincial Secretary, this 1st day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 2573-05 Super-Marché Laguë inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quel>ee Companies Act, letters patent, bearing «late the 4th «lay of June, 1966, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Veilleux, chartered accountant, Jacques O'Breatly, advocate, both of 230 King West, Sherbrooke' and Normand Laguë, merchant, Farnham, for the following purposes: To carry on business as grocers-butchers, uiuler the name of \"Super-Mandié J.aguë inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of a nominal value of 8100 each and 200 preferrc«l shares of a nominal value of 8100 each.The head oflice of the company will be at Farnham, judicial district of Betford.Given at the office of the Provincial Secretary, this 4th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 2592-05 Terbeau Agency Ltd.Notice is hereby given that uiuler l'art.I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 31st tlay of May, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Roger Beau-lieu, advocate and Queen's Counsel, 4125 Blue-ridge Crescent, Montreal, Eugène Jurisic, advocate, 4870 Côte-des-Neiges, Montreal, and J.- t QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1965, Vol.97, No.29 3803 Neiges, Montréal, et J.-Bernard Carisse, avocat, .\".s.iO, |)e Brissae, Anjou, pour les objets suivants: Kxerccr le commerce d'avocats, d'agents ou autrement tout mandataire pour l'administration et la surveillance d'édifices et la perception de loyers, bous le nom de « Terbeau Agency Ltd.¦ , avec un capital total de 81,01)0, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le si chacune.Le siège social de la compagnie sera à Montréal, «listriet judiciaire de Montréal.Donné au bureau du secrétaire «le lu province, c c 31e jf the Quebec Companies Act, letters patent, bearing «late the 8th day of June, 1065, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, incorporating: Normand C.Denys, lawyer, 110 Jasper, Mont-Royal, René Bcaulac, lawyer, 20S Molières Street, Laval-des-Rapides, and Michèle Lavoie, secretary, fille majeure in the full enjoyment of all her rights, 1383 St-Louis Street, St-Laurent, for the following purposes: To carry on business as grex'ers and butchers, under the name of \"Viaiule Menhar inc.\u2014 Menhar Meat Inc.\", with a total Capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company will be at LaSalle, judicial «listriet of Montreal.Given at the oflice of the Provincial Secretary, this 8th day of June, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 \u2022 2072-05 La Vieille Maison Blanche inc.Ye Olde White House Inc.Notice is hereby given that under Part I of the Quebec Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of May, 1905, have been issuetl by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, incorporating: Bernard Liboiron, innkeeper, Préfontaine Street, André Bertrand, chartered accountant, 41 St-Venant Street, ami Paul Gélinas, lawyer, Normandie Street, all three of Ste-Agathc-iles-Monts, for the following purposes: To ojK'rate hotels, motels, taverns, inns ami restaurants, under the name of \"La Vieille Maison Blanche inc.\u2014 Ye Okie White House Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,000 common shares of 810 each and into 100 preferreil shares of 8100 each.The head oflice of the company will be at Ste-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1966, Vol.97, No.29 3865 Donné au bureau du secrétaire «le la province, k 25c jour de mai 1905a Le Sous-xccréiairc de la province, Raymond Douvillk.11415m 2:580-65 V.G.I.construction liée Avis eat donné qu'en vertu «le la première partir de la Loi dei compagnies Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 21st «lay of May, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «»f Quebec, t«> \"Les Chantiers de Chibougarnau ltée , increasing its capital stock from S0O.OOO to 820O.(MX), the additional share capital being «livide»! into 20,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1905.Raymond Dou vii.i.k, Assistant Secretary of the Prorincc.11415 10297-01 \u2014 1277/8 Charier Credit Corporation Notice is hereby given that, umler Part I «)f the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 20th «lay of May, 1905, have Ik-cii issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province of Quebec, to \"Charter Credit Corporation**, modifying the rights attaching to its Series \"A\" preferred shares.(Jiven at the «)fficc of the Provincial Secretary, this 20th day of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11115-0 14859-01 \u2014 1277/73 Cofiad Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th «lay of April, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Cofia«l Inc.\", subdividing its 392,000 common shares of a nominal value of 85 each into 784,000 class \"A\" shares of 82 each and 392,000 class \"B\" shares of 81 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 29th day of April, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 14304-53\u2014 1277/90 Columbia Electric Limited Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 20th day of May, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Columbia Electric Limited\", increasing its capital by the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1965, Vol.97, No.29 3807 augmentant ton capital par la creation de 56,000 actions privilégiées «l'une valeur au pair «le 810 chacune.Donné au bureau «lu secrétaire «!«' la province, ce 26e Joui .Ltd.*, 1° annulant 100 actions privilégiées «l'une valeur au pair r«lc.par le lieutenant-gouverneur «le la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 17c jour «le mai 1905, à la compagnie « Domaine Seigneurial «le Montarvillc inc.\u2014De Montarvillc Seigneurial Domain [ne.*, 1° convertissant ses 2,950 actions ordinaires «l'une valeur nominale «le 81 chacune en 29,500 actions ordinaires sans valeur nominale; 2° augmentant son capital par la création de 10,500 actions ordinaires sans valeur nominale et par 10,500 actions privilégiées «le 810 chacune.Donné bu bureau «lu secrétaire «le la province, «e 17c jour «le mai 1905.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.11415-0 4423-03 \u2014 1277/1 ai Durocrcte ltée Durocrctc Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Quéoec, il a «\u2022lé accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, «les lettres patentes supplémentaires, en «late «lu 1er jour de juin 1905, à la compagnie « Béton précontraint ltée \u2014 Precast Concrete Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 15c jour de janvier 1964, échangeant son nom en celui de « Durocrete ltée \u2014 Durocrete Ltd.» ; 2° convertissant ses 3,000 actions non émises de 810 chacune en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Donné au bureau du secrétaire de la province, ce 1er jour de juin 1905.Le Sous-secrêtaire de la province, Raymond Dou ville.11415-0 116-64 \u2014 1277/45 creation of 50,000 preferred shares of the par value of 810 each.(liven at the oflice of the Provincial Secretary, this 20th «lay of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 8588-45 \u2014 1277/43 Danmor Shoe Co.Ltd.Notice is hereby given that, under Part I of the Quelx'i: Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 14th «lay «,f April, lot,.\",, have been issued by the Lieutenant-Governor f the Province of Quelx-e, to \"Danmor Shoe Co.Ltd.\", 1.cancelling 100 preferred shares of the par value of 8100 each; 2.subdividing its KM) Unissued preferred shares «>f the par value of 8100 each into 10,000 preferred shares of the par value «>f 81 each; 3.increasing its capital by the creation of 200,000 preferred shares of the par value of 81 each.(iiven at the ollice t>f the Provincial Secretary, this 14th «lay of April, 1905.R aymo.n i) dou villk, Assistant Secretary of the Province.11415-0 4155-53\u2014 1277/9 Domaine Seigneurial de .Montarvillc inc.De Montarvillc Seigneurial Domain Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 17th «lay of May, 1905, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Domaine Seigneurial de Montarvillc inc.- De Montarvillc Seigneurial Domain Inc.\", 1.converting its 2,950 common shares of a nominal value of 81 each into 29,500 common shares of no nominal value; 2.increasing its capital stock by the creation of 10,500 common shares of no nominal value ami 10,500 preferred shares of 810 each.(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 17th day of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 4423-03 \u2014 1277 101 Durocrete liée Durocrete Ltd.Notice is hereby given that, umler Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing «late the 1st day of June, 1965, have been'issued by the Lieutenant-Governor of the Province of Quebec, to \"Béton précontraint ltée \u2014 Precast Concrete Ltd.\", incorporated by letters patent tlated the 15th day of January, 1964, 1.changing its name to that of \"Durocrete hee \u2014 Durocrete Ltd.\"; 2.converting its 3,000 unissued shares of S10 each into 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.Given at the office of the Provincial Secretary, this 1st day of June, 1965.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 116-64 \u2014 1277/45 8868 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 17 juillet 1965, 97' année, No 29 Lea Entrepôt* Adanac inc.\\f 81 each; 2.converting ami subdividing its 390 unissued common shares of 6100 each into 3,900 unissued common shares of a nominal value of 810 each.(iiven al the office of the Provincial Secretary, this 21st day of May, 1905.Raymond Douvillk, Assistant Secreturi/ of the Province.11415 1685-64\u20141277/40 Entreprises Couture inc.Couture Enterprises Inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th «lay of May, 1065, have been issuetl by the Lieutenant - Governor «>f the Province of Quebec, to \"Entreprises Couture inc.\u2014 Couture Enterprises Inc.\", amending the privileges and restrictions attached to class A\" and class \"C\" preferred shares.(iiven at the ollice of the Provincial Secrelarv, this 25th day of May, 1905.Raymond Doi;villi:.Assistant Secreturi/ of the Province.11415 11660-61 \u2014 1277/121 Les Entreprises Harricana liée Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 10th «lay of June, 1965, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province «>f Quebec, to \"Bellisle & Viens inc.\", incorporated by letters patent dated the 20th day of April, 1904, changing its name to that of \"Les Entreprises Harricana ltée\".(iiven at the office of the Provincial Secretary, this 10th day of June, 19G5.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.11415 1054-04 \u2014 1278/39 Fascination Haute Coiffure inc.Notice is hereby given that, under Part I of the Quebec Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd «lay of June, 19G5, have been issued by the Lieutenant-(iovernor of the Province of Quebec, to \"Les Produits «le beauté Fascination inc.\", incorporâted by letters patent dated the 5th «lay of December, 19G3, changing its name to that of \"Fascination Haute Coiffure inc.\".(iiven at the oflice of the Provincial Secretary, this 3rd day of June, 1965.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.11415-0 5347-63 \u2014 1277/106 Foyer des Bois Francs inc.Notice is hereby given that, the provisions of the Quebec Companies Act supplementary QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 17, 1906, Vol.97, No.29 accordé, par |q ueutenant-gouveroour do la province de Québec, dee lettres patentee supplémentaires, en date du l()e jour «le juin L965, à la corporation « Foyer dee Hois France inc.», 1° étendant ses pOU voire i 2° augmentant le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir «-t posséder ladite corporation de 15,000 j 1350,000.Donné au bureau «lu secrétaire «le la province, ce 10e jour de juin 1005.Le Sons-sccrctuire di lu produce, Raymond Douvim.k.11415 15014-01 - 1378/41 Frontenac Packing l.id.\\\\is «-si donné qu'en vertu «!«\u2022 la première partie «le la Loi «les compagnies «le Québec, il a été BCOOrdé, par !«\u2022 lieutenant-gouverneur «le la province «!
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.