Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 15 avril 1967, samedi 15 (no 15)
[" no* an m':f- vol.99 N° 15 2485 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 13 avril 1967 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur r Zéphirin Côté, doctor, 2350 Des Cascades.Koch Rousseau, 2290 Dcncault, Valmore Doirou.170 Brooks, both machinists, Cécilien Mathieu, tracer, 1300 Daniel, and Jean-Guy Arehanil>;iult.professor, 399 Meilleur, all seven of Sherbrooke) for the following purposes: To promote a civic spirit and a sense of responsibility among all its citizens, under the name of \"L'Action civique de Sherbrooke inc.\".The amount to which is limited the value of the immoveable property which the corporation may acquire and possess, is $20,000.The head office of the corporation is at 2106 King Street West, Sherbrooke, judicial district of Saint-Francis.Raymond Dou villi:.Aasixtant Secretary of the Province.19228 l7.\")-ti7 Aitken Studios Ltd.Notice is given that under Part I of the ( 'oni-panics Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1907, have been issued by *ut Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marvin Aitken, photographer, 5841 Decelles Place, Montreal, Hugh A.Rowe.re- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 1',, 1907, Vol.99, So.10 2487 II,m!i A.Howe, analyste eu recherches, S140, Nilln¦1-IVlU'lier, et Taylor Cahill, agent de change, 8251, Wilfrid-l'elleticr, ces deux derniers J'.Vn uu, pottr les objets suivants: Exercer le commerce de photographes et de reproducteurs de tableaux et agir comme artistes et artistes commerciaux, sous le nom de « Aitken Studios Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires de $1 chacune et 395 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228 580-07 Allaire & Laguc inc.Avis est.donné cpi'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour «le mars 1907, constituant en corporation: Lucien Laguc, 20, rue Atvhambault, Bernard Allaire, 17, rue Gosselin, tous deux courtiers en assurances, et Jean-M .< îagnon, comptable agréé, 134, boulevard Magenta, tous trois de Farnham, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Allaire & Lague inc.avec un capital total «le $80,000, divisé en I11\" actions ordinaires de $100 chacune et en 7llli actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 178, rue St-Paul, Farnham, district judiciaire de Bedford.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.19228m 841-07 Les Vmis du Musée d'art contemporain Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le licutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres pat.nies, en date «lu 30e jour «le décembre 1900, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Mandeville, politicologuc, 12004, Val-mont, Paul Thibault, ingénieur, 7721, Jean-Bourdon, Denis Lévesqe, avocat, 3270, rue Sherbrooke est, Armand Robert, administrateur, 2000, Place Henri-Bourassa, Jacques DeMont-joye, couturier, 1023, rue Selkirk, tous cinq de Montréal, Jean-Louis Delorimicr, publicitaire, 65, me Prospect, Westmount, et Claude Vermel le.«-éramiste, Sainte-Adèle, pour les objets suivants: Collaborer avec le Musée d'art contemporain de Montréal à l'accomplissement «le sa mission culturelle en organisant «les manifestations d ordre social, culturel et artistique, sous le nom de Les Amis «lu Musée d'art contemporain ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est «le $500,000.Le siège social «le la corporation est 1312, rue Sherbrooke est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.5431-00 Anglo-French Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de \\a l0j jeg compagmes> |e fieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres search analyst, 8140 Wilfrid-I'clletier, and Taylor Cahill, stock trader, 8251 Wilfri.l-Pelletier, the latter two of Anjou, for the following purposes: To carry on business as photographers and reproducers of pictures ami to act as artists ami commercial artists, under the name of \"Aitken Studios Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 500 common shares of SI each and 395 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.19228-0 580-67 Allaire & Lague inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of March, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucien Lague, 20 Archainbault St., Bernard Allaire, 17 Gosselin St., both insurance brokers, and Jean-M.Gagnon, chartered accountant, 134 Magenta Blvd., all three of Farnham, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, un«ler the name of \"Allaire & Lague inc.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 100 common shares of $100 each ami 700 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 178 St-Paul St., Farnham, judicial district of Bedford.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.19228 841-07 Les Amis du Musée d'art contemporain Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1900, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Marcel Mande ville, political scientist, 12004 Valmont, Paul Thibault, engineer, 7721 Jean-Bourdon, Denis Lévcsque, lawyer, 3270 Sherbrooke Street East, Armand Robert, director, 2000 Place Henri-Bourassa, Jacques DeMontjoye, tailor, 1023, Selkirk Street, all five of Montreal, Jean-Louis Dclorimier, publicist, 05 Prospect Street, Westmount, and Claude Vermette, ceramist, Sainte-Adèle, for the following purposes: To collaborate with the Montreal Museum of Contemporary Art for the accomplishment of its cultural mission by organizing manifestations of a social, cultural and artistic order, under the name of \"Les Amis du Musée d'art contemporain\".The amount to which is limited the immoveable property which the corporation may acquire and possess, is $500,000.The head office of the corporation is at 1312 Sherbrooke Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dou ville, Assistant Secretary of the Province.19228 5431-00 Anglo-French Enterprises Inc.Notice is given tlu*t under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of February, 1907, have been issued 2488 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'EllEC.ta avril 1967, 99' année, »\u2022 jô patentes, ni (lato «lu 21c jour «le février 191)7, conatituant en corporation: Murray B.Spiegel, 03, chemin Banstcad, Montréal Ouest, Etarvev Cooperstone, 1448, Beverly Creacenti Laval, tous deux avju'ats.et Franchie Yégiard, secrétaire, célibataire, 3105, Hutcliison, M mil irai.pOlir les objets suivants: Exercer le commerce d'agents en immeuble, sous le nom «le « Anglo-French Enterprises Inc.¦\u2022.avec un capital total «le S 10.0(H).divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 110,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.l.e Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillb.19328 825-67 L'Association des fonctionnaires des Affaires culturelles (AFAC) Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi «les c«>mpagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «laie «lu 7c j«>ur «le février 1967, constituant en eorporalion sans capital actions' Robert Morissette, adjoint administratif, 782, Le Cavelîer, Sainte-Foy, .lean Létourneau, assistant-comptable, 5837) «les Glaïeuls, Onainville, et Lise 1 biliaire, agent «le bureau, fille majeure.353, de la Reine.Québec, pour les objets suivants: Grouper les fonctionnaires «lu ministère des Affaires culturelles aux fins «l'entraide, sous le nom «le « L'Association «les fonctionnaires «les Affaires culturelles (AFAC) \u2022>.Le montant auquel sont limités les revenus annuels «les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le 850,000.Le siège social «le la corporation est à Québec, districl judiciaire «le Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DouviLLB.19228m 532-07 Association des Loisirs de St-David-d'Yaniaska inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 15e jour «le février 1967, constituant eu corporation sans capital-actions: Georges Danis, étudiant, Louisma Desrosiers.entrepreneur, et Gérald Cava, électricien, tous trois «le Saint-David, pour les objets suivants: L'organisation «les loisirs, sous le nom «le « Association «les Loisirs «le St-I>nvid-d'Yamaska inc.».tie montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le 850,000.Le siège social de la corporation est à Saint-David, district judiciaire de Richelieu.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.19228* 998-66 Association des parents de la Région Yamaska Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 23c jour «le février 1967, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Guy Gauvin, dessinateur, 475, rue Millette, Cailles Robert, assistant-directeur, 1125, rue Bourassa, tous deux «le Saint-Hyacinthe, et Ro- by the Lieutenant-Governor of the Province incor(m>rating: Murray B.Spiegel, 03 liaiutead Road, Montreal West, Harvey Coop -Unie, 1448 Beverly Crescent, Laval, both advocates, and Franchie Végiard.secretary, spinster, 3465 Hutchison, Montreal, for the following purposes, To carry on business as real estate agents, under the name of \"Anglo-French Enterprises Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 10*000 common shares «»!* $| each and 30,000 preferred shares t>f SI each.The head office «>f the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dot vu Assistant Secretary of the Produce.19228-0 #3417 L'Association des fonctionnaire-des Affaires culturelles (AFAC Notice is given that under l'art III of tbe Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province u> incorporate a corporation without share capital: Robert Morissette, administrative nasi «tant, 782 Le Cavalier, Bainte-Foy, .lean Létourneau, ten* tant accountant, 5837 «les Glaïeuls, Orsaittville, an«l Lise Dalla ire.ollice clerk, fille majeure, 3S3 «le la Reine, Quebec, for the following purposes: To group the functionaries of the Department of Cultural Affairs for the purjm.se «>f mutual aid, under the name of \"L'Association des fonctionnaires «les Affairai culturelles (AFA< !)\".The amount to which is limited the annual revenue of the immoveable property which the corporation may acquire and possess, is $50,000.The bead ollice of the corporation is at Quebec, judicial district «>f Quebec.Raymond Dorvn.i i .Assistant Secret an/ of the Proi1 tee.19228 5324Ï Association des Loisirs de St-David-d'Yamaska urne.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Georges Danis.student, Louisma Desrosiers, contractor, ami Gerald Cava, electrician, all three of Saint-David, for the following purposes: The organization of a recreational center, under the name of \"Association «les Loi ira 'If St-David-d'Yamaska inc.\".The amount to which is limited the value uf the immoveable property which the corporation may acquire ami possess, is S50.000.The head office of the corporation is at Saint-David, judicial district of Richelieu.Raymond Dor villi:.Assistant Secretary of the I'm, 1922S «-66 Association des parents de la Région Yamaska Notice is given that under l'art III ol UK Companies Act, letters patent, bearing dale tl'*' 23rd day of February, 1907, have been issued of the Lieutenant-Governor of the Province i«» incorporate a corporation without sahre capital: Jean-Guy Gauvin, draughtsman, 475 Millette St., Gilles Robert, assistant-director, 1125 Boo-rassa St., both of Saint-Hyacinthe, and Rosaire QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, m7.Vol.89, So.13 2489 leur* d'édi \u2022 Km u l.llll lu CO I.Ilvi |f»2- Malit, tcchuologislc agricole, 500, rue Cou- I >i>iiville, polir les objets suivunts: iiiiel I re aux parents de prendre conscience de obligation! et de leurs droits duns l'oeuvre ii de leurs enfants, sous le nom de ! il ion des parents de la Région Yamaska ».montant auquel est limitée la valeur «les immobiliers que peut enquérir et posséder juration, est de $1.000,000.c social «le la corporation est à Saint-it he, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.l.r Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.792-67 Les Vssiiranccs J.-R.Lepage inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première parlie f the corporation is at Saint- Hyacinthe, judicial district f Saint-Hyacinthe.R a y mo n d I)«) i; vi lle, Assistant Secretary of Ike Province.1922s 792-67 Les Assurances J.-R.Lepage inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of January, 1907, have bean issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: J.-Romuald Lepage, insurance agent, Omérille Michaml, charwoman, wife separate as to pro|>crty «>f Wilfrid Michaud.both of Saint-Germain-de-Granthani, and Roger Parenteau.a«lvocate, 480 St-Jean.Drummond -ville, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers ami agents, under the name of \"Les Assurances J.-R.Lepage inc.\".with a total capital stock of $40,(KM), divided into UK) common shares of a nominal value of 810 each and 390 preferred shares of a nominal value «>f $100 each.The head office of the company is at Drum- mondville.judicial district of Drummond.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.19228 166-67 Ba Ba Wool Shop (Montreal) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, Iwaring date the 21st day of February, 1907, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: William Loin- Amos, real estate agent, Eithne Mac Namara Law, executive, wife separate as to property of the sai«l William Louis Amos, both of 49f>4 Roscdale, and Philip Benjamin, lKK)kkec|K'r, 4700 Bourret Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitted goods of all types, under the name of \"Ba Ba Wool Shop (Montreal) Inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 100 common shares of a par value of $10 each ami 390 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company is at 0570 Somerled, Montreal, judicial district of Montreal .Raymond Doiville, Assistant Secretary of the Province.19228-0 750-07 Antonin Bachand & fils liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 23rd day of February, 1907, have been is;suc«l by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antonin Bachand, insurance broker, Fleure-Angc Courtemanchc, housewife, wife of the said Antonin Bachand, and duly authorized by him for these presents, both of 509 Boivin Blvd., and Jean-Marie Bachand, insurance 2490 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 15 avril 19C7.99' année, n° 15 Marie Bachand, agent d'assurance, 542, Mercier, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Faire aifaircs connue courtiers et agents en assurance, sous le nom de « Antonin Haeliaud & fils liée», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires tie $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le Sous-sécrétaire de la province, Raymond Dou ville.19228-q 787-07 I*.Blaquièrc construction liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres Détentes, en «late «lu 15s jour «le février 1907, constituant en corporation: Jean-Marc Bouchard, 31, Miramont, Xeufchatel, Claude Roycr, 2785.Poitiers, Saintc-Foy, tous deux notaires, et Paul Blaquièrc.vendeur, 185, avenue Notre-Dame, Notre-Dame-dcs-Laurentides, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et «le construction, sous le nom de « P.Blaquièrc construction ltée », avec un capital total «le 840,000, divisé en 400 actions onlinaires de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 1398, Lyonnais, Orsainville, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.19228-o 055-G7 Brady Realties Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late du 20e jour de février 1907, constituant en corporation: Harry Aronovitch, avocat et conseil en Loi «le la reine, 5023, Randall, Arthur I.Bronstein, 5703, KIdridgc, tous deux «le Côte St-Luc, et C.Ralph Lipper, 4350, ouest, rue Sherbrooke, Montréal, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Exercer le commerce «l'une compagnie d'immeubles, «le placements et «le portefeuille, sous le nom «le « Brady Realties Corporation», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune, 1,000 actions privilégiées catégorie « A » «l'une valeur au pair «le 81 chacune et 38,000 actions privilégiées catégorie « B » «l'une valeur au pair «le SI chacune.Le siège social de la compagnie est 3333, chemin de la Reine Marie, suite 310, Montréal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.19228 5445-66 C.P.C.Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en date du 1er jour de mars 1967, constituant en corporation: Marcel Latouche, enployé civique, Françoise Chapleau, ménagère, épouse séparée de biens dudit Marcel Latouche, et dûment autorisée par lui aux fins «les présentes, tous deux «le 4845, St-Zotique est, Jacques Lalondc, photograveur, 10149, St-Urbain, Martine Vézina, secrétaire, fille majeure, 10243, Esplanade, André Lacliance, pharmacien-chi- ngent, 512 Mercier, all three of Granby.for the following purposes: To carry on business as insurance brokers ami agents, under the name of \"Antonin Bachand & fils ltée\", with a total capital stock of > 10,000, divided into 400 common shares of SUM) each, The head ollice t>f the company is at (iranby, judicial «listrict of Bedford.Raymond Dot -villi:, .Issistant Secretary of the Pro\\ ¦ ¦\u2022.19228 78741 P.Blaijuicrc construction liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marc Bouchard, 31 Mira-mont, Neufchatel, ('lainle Rover, 2785 Poitiers, Sainte-Foy, both notaries, and Paul Blaquière, salesman, 1S5 Notre-Dame Ave., Notre-I bmie.des-Laurentides, for the following purposes: To carry on business as real estate and construction company, under the name of \"P.Blaquièrc construction ltée\", with a total capital stock of 840,000.divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 1398 Lyonnais, Orsainville, judicial district «il Que.I>ec.Raymond Dou villi:.Assistant Secretary of the Province.1922s 655*67 Brady Realties Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Harry Aronovitch, advocate and Queen's Counsel, 5023 Randall, Arthur I.Bronstein, 5703 Eldridgc, both of Côte Saint-Luc, an«l C.Ralph Lipper, 4350 Sherbrooke Street West, Montreal, the latter two advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, investment and holding company, under the name of \"Bradv Realties Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each, 1,000 class \"A\" preferre«l shares of the par value of $1 each and 38,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 3333 Queen Mary Road, suite 310, Montreal, judical district of Montreal.Raymond Dou villi.Assistant Secretary of the Province.19228-0 5445-66 C.P.C.Québec inc.Notice is given tliat under Part I «>l the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1907, have been issue i by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Latouche, civic employee, Françoise Chapleau, housewife, wife separate as to property of the said Marcel Latouche.and «luly authorized by him for these presents, both of 4845 St-Zotique East, Jacques Lalonde, photo* engraver, 10149 St.Urban, Martine Yé/ma.secretary, fille majeure, 10243 Esplanade, Andre Lachance, pharmacist-chemist, 12230 Jasmin, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April lô, 1967.Vol.99, So, 15 2491 miste, 12230, Jasmin, et Laurier Richard, surintendant, 10535, Sackville, tous six de Montréal, pour le» objets suivants: Distribuer et vendre en gros ou en détail tous produits pharmaceutiques, chimiques, alimentaires sanitaires ou autres, sous le nom de «C.P.C.Québec inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires de s!nu chacune et en K.OOO actions privilégiées de $10 ehaeune.I.e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.if 840,000.divided into 5.000 common shares of 81 each and 35,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond DouviLLE, Assistant Secretary of the Province.19228-0 844-67 Le Centre éducatif Lauren tien inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Yvon Côté, salesman, Diane Launier, housewife, wife of the said Yvon Côté, both of G0S2 De Bellefeuille St., Saint-Léonanl, and Louis Brunei, accountant, 12273 de Poutrincourt, Montreal, for the following purposes: I To operate a center for the leaching, preparing, conducting and giving of language courses. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 avril 19H7, 99' année, n° 15 2492 nom de « Le Centre éducatif Laurentien inc.», avec un capital total de S40,(XX), divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur nominale de $10 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de §100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Michel, «listrict judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond 1)«»i;vii.i.k.19228*0 4819-66 Châteauguay Regional Shopping Plaza Merchants' Association Avis est donné qu'en vertu de la tr«>isième partie «le la Loi «les compagnies, le licutcnant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late «lu 22e jour «le février 1907, constituant en c«>rporati«>n: Paul Harvey A.Hubscher, comptable agréé, 5703, avenue White- home.Montréal, .1.('.Théroux, 191, rue Dubé, Chftteauguay, Normand Gauthier, 85, Gilbert, Châtcauguay-( 'entre, tous «leux gérants, et Jacques Villeneuve, marchand, 294, Ramlill, Chftteauguay, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts communs des marchands de Chftteauguay Regional Shopping Plaza, sous le nom «le « Châteauguay Regional Shopping Plaza Merchants' Association », La corporation ne pourra posséder ni détenir aucune propriété immobilière.Le siège social «le la corporation est à Chftteauguay, «listrict judiciaire «le Bcuuharnois.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvii.i.k.1922S 70S-O7 Cité Jeunesse inc.Avis est donné «ju'en vertu de la troisième partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en date «lu Me jour «le février 1967, constituant en corp«>rntion sans capital-actions: André Railly.4339.De Lorimier.Jean-Yves Bernard, 853, Du Couvent, tous «leux étudiants, Serge Biron, 3402.Gertrude, Jean-Marc Girard, 2737.Cuvillicr, et Louise Lalonde, fille majeure.0703, Lamont.ces trois derniers professeurs, tous cinq de Montréal, pour les objets suivants: Opérer un terrain «le camping spécialement destiné à l'usage et au service «le la jeunesse qui viendra visiter l'Exposition Universelle «le 1907, à Montréal, sous le nom «le « Cité Jeunesse inc.» .Le montant auquel sont, limités les biens immobiliers «pic la corporation peut acquérir et posséder, est «le SI5,000.Le siège social de la corporal ion est.à Montréal, district judiciaire «le Montréal, Le Sous-secrétaire de la province.Raymond DouviLLE.19228-0 571-07 Club de Chasse et de Pêche Maska inc.Avis est donné qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi «les compagnies, il a été accordé par le lieutenant-gouverneur «le la province «les lettres patentes, en date du 23 novembre 1966, convertissant en corporation sans capital-actions, la compagnie « Club «le Chasse et de Pêche Maska inc.», constituée en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies le 20 juin 1957, et ce, pour les objets suivants: umler the name of \"Le Centre éducatif bauren.tien inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of 810 each ami 300 preferred slum - of a nominal value of $100 each.The head ollice of the company is at Saint.Michel, judicial district of Montreal, Raymond DotJVILLK, Assistant Secretary of the Province.19228 4819416 Châteauguay Regional Shopping Plaza Merchants' Association Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province to incorporate a corporation without share capital: Paid Harvey A.rtubseher, chartered accountant, 5703 Whitchorne Avenue, Montreal, .1.('.ThéroUK, 191 Dubé Street, Châteauguay.Normand Gauthier, 85 Gilbert, Chateauguay-< 'entre, both managers, anil Jacques Villeneuve, merchant, 294 Ramlill, Châteauguay, for the follow, ing purposes: To promote the common interests of the merchants of the Chftteauguay Regional Shopping Plaza, under the name of \"Chftteauguay Regional Shopping Plaza Merchants' Associa* tion\".The corporation shall not own nor boll any immoveable property.The head office of the corporation is al Châteauguay, judicial «listrict of Beauharnois.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.10228-o 7684?Cité Jeunesse inc.Notice is given that under Part III of I be Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: André Bailly, 1339 De Lorimier, Jean-Yves Bernard, S53 Du Couvent, both students.Serge Biron, 3402 Gertrude, .lean-Man- Girard, 2737 Cuvillicr, and Louise Lalonde, fille majeure, 0703 Lamont, the latter three professors, all five of Montreal for the following purposes: To operate camping grounds specially dest ined f«>r the use and service of youths visit int.' the 1967 Universal Exhibition in Montreal, under the name of \"Cité Jeunesse inc.\".The amount to which is limited the inline* veable property which the corporation may acquire and possess, is 815.000.The head office of the corporation is at .Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Province.1922S 5714\" Club de Chasse et de Pêche Maska inc.Notice is hereby given thai under Pari III «»f the Companies Vet.the Lieutenant-Governor «>f the Province has granted letters patent, dated November 23, 1966, incorporating, without capital shares, \"Club «le Chasse et de Pêche Maska inc.\", incorporated umler Part I of the Companies Act on June 20, 1957, and such, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1907, Vol.99, \\o.15 2493 Aii!à faire observer les lois et les règlements concernant la protection «lu gibier et «lu poissou ilaii- Id province; pr«>inouvt>ir l'esprit sportif en ce concerne la «'basse et la pêche «lans le «lis-tri> t «!e Sl-llya«intlie.I.c montent ampiel sont limités les revenus provenant ssé«lcr la corporation, est «le 850.000.Le siège s«>«-ial «le la corporation est à Québec, districl judiciaire «le Québec Le Sous-secrétaire de la province.Raymond douville.19228m 609-67 To held to respect the laws ami regulations concerning the protection of fish ami game in the Province; to promote a sport ice spirit in that which concerns fish ami game in the «listrict of St-Hyacinthe.The amount to which is limited the revenue Coming from the immoveables which the corporation may acquire ami possess, is >'2.0t!0.The head Office of the new corporation is at St-Hyacinthe, judicial district of St-Hyacinthe.Raymond DouviLLE, Assistant Secretaru of the Province.1922S 11816-57 Le Comité des citoyens «le l'aire No 10 Notice is given that umler Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 13th day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: \u2022lean Méthé, civil engineer, 371 Langelicr Boulevard, Achille Simard, functionary, 508 Dablond, and Jeanne «l'Are Paradis, housewife, wife of Gérard Bélanger, 557 Ste-Hélène, all three «»f Quebec, for the following purposes: To obtain the maximum «>f coliabaration from the (iti/ens of area No.10.«>f the «-ity and Pr«>- vinee of Quebec for the rearrangement of the area by study ami social animation, under the name of \"Le ('«unité «les citoyens «le l'aire No.10\".The amount to which is limited the value of the immoveable pro|>erty which the corporation may acquire ami possess, is 150,000.The head office of the corporation is at Quebec, judicial «listrict of Quebec.Raymond Dorvu.i.i:.Assistant Sccretury of the Province.19228 009-07 Concessions du Village International inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «!e la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a a«'cor«îé «les let t rcs patentes, en date «lu 0e jour «le février 1907, constituant en corporation: Denyse Crête, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Lionel Grcnon, 5206, s,, avenue, Montréal, Claude Constanti-aeau, notaire, 7923.boulevard Wilfrid-Pelletier, Anjou, et Suzanne Laln-rge, secrétaire, fille majeure, 7130.rue Michelet, Saint-Léonanl, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom «le « Concessions «lu Village International inc.», avec un capital total tic 1125,000, divisé en 25,000 actions onli-naires de 85 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Longueuil, districl jmliciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond DOUVILLE.19228-0 492-07 \u2022 a Corporation financière Laurentienne l.aiircntienne Finuneial Corporation Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 3c jour «le mars 19(57, constituant en corporation: Owen Carter, 2177, Hnilni t.Sillery, Jean Leahy, 255, avenue Laurier, Quebec, tous «leux avocats et conseils en Loi «le la reine, et Agnes J.Cordon, secrétaire, veuve de Concessions du Village International inc.N«)ti«'e is given that umler Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the oth day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Denyse Crête, secretary, wife separate as to property of Lionel Grenon, 5206, 8th Ave.Montreal, Claude Constantincau, notary, 7923 Wilfrid-Pelletier Blvd., Anjou, ami Suzanne Laberge, secretary, fille majeure.7130 Michelet St., Saint-Léonanl, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns anil restaurants, under the name of \"Concessions du Village International inc.\", with a tolal capital stock of 8125.000.divided into 25,000 common shares of 85 each.The head office of the company is at Longueuil.judicial «listrict of Montreal.Raymond Dot vn.i.i:.Assistant Secretary of the Province.19228 492-67 La Corporation financière Laurentienne Laurentienne Financial Corporation Notice is given taht under Part I «>f the Companies Act, letters patent, bearing «late the 3r«l «lay of March, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor t>f the Province, incorporating: Owen Carter, 2177 Brûlart.Sillery, Jean Leahy, 255 Laurier Avenue, Quebec, both advocates ami Queen's Counsels, and Agnes J.Gordon, secretary, wi«low of Robert H.T. 2494 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, tû avril 1907, 99' année, n\" 15 Robert H.T.Cordon, 12S1, Jean-Dequen, Suintt'-Foy, |>our les objets suivants: Fuire affaires comme compagnie «l'immeuble, «le construction et «le financement, sous le nom «le «La Corporation financière Laurentienne -Laurentienne Financial Corporation», avec un capital total de 11,000,000, divisé en 100,000 actions ordinaires «le 85 chacune et en 100,000 actions privilégiées de 85 chacune.Le siège social de la compagnie est S12, rue Décary, Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, RaYMOX I) 1 >OUVILLE.19228^» 919-07 Gordon, 12SI Jean-Dequen, Sainte-Foy, for tlu-followiug DUrpOfMi To carry on business as a real estate, constine.tion ami financing company, umler the name of \"La Corporation financière Laurentienne \u2022 Laurentienne Financial Cor|x>ration\", with a total capital stock of §1,000,000.divided into 100,000 common shares of 85 each ami 100,000 preferred shares of 85 each.The head office of the c«>mpany is al M2 Décary Street, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Province.19228 949417 Distributeurs Lasalle inc.Lasalle Distributors Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé' «les lettres patentes, en «late «lu 10e jour «le février 1907, constituant en corporation: Antoine Paré, ill\"), Sherbrooke ouest, John Archambault, 5724, Deom, tous «leux «le Montréal, et Alphonse Barbeau, S47, Dunlop, Outremont, tous trois avocats, jxmr les objets suivants: Exploiter des postes «le service, «les postes d'essence, «les parcs «le stationnement et constructions de toutes sortes, sous le nom «le « Distributeurs Lasalle inc.\u2014 Lasalle Distributors Inc.», avec un capital divisé en 310 actions ordinaires sans valeur nominale et en 000 actions privilégiées «le 810 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.1022S-o 491-07 Distributeurs Lasalle inc.Lasalle Distributors Inc.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1907, have been inasd by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antoine Paré, 1115 Sherbrooke St.West, John Archambault, 5724 Deom, both of Montreal, and Alphonse Barbeau, 847 Dunlop, Outremont, all three ael-sur-Qué-villi'ii.et Maxime Langlois, avocat, 1439, chemin Ste-Foy, Québec, pour les objets suivants: Administrer et gérer un hôpital publie, sous le nom île « Hôpital bel ici ».I.e montant ampiel est limitée la valeur des biens immobiliers (pie peut acquérir et posséder la corporation, est de 82,000.000.Le siège social «le la corporation est à Lebel-xur-Québillon, district judiciaire d'Abitibi.Le Sous'sccrctairc de la province.Raymond Douville.I922S-0 5112-00 Hôpital I «bel Notice is given that under Part III of th Companies Act, letters patent, bearing «late the 16th day of January, 1067, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital : Dr.Marc Arsenault, doctor, Mr.Benott Rousseau, priest, both of Lebcl-sur-Quévillon.ami Maxime Langlois, lawyer, 1439 Sle-Foy Road, Quebec, for the following purposes: To direct and manage a public hospital, umler the name of \"Hôpital Lebel'*.The amount to which is limited the value of the immoveable property which the corporation may acquire ami possess, is 82,000.000.The head office of the corporation is at Lebel-sur-Quévillon, judicial «listrict of Abitibi.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.1922S 5112-00 Les Industries Valdex limitée I.es Industries Valdex limitée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutcnant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late «lu 20c jour «le février 1907, constituant en corporation: Alex Dubois, homme d'affaires, Huguette Dubois, ménagère, épouse séparée oratoire «lu Dr Renaud (Division Canada) inc.», avec un capital total «le 810,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 2873, chemin Stc-Foy, Sainte-Foy, «listrict jmliciaire «le (Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10228-o 520-07 Laine Longucuil Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé «les lettres patentes, en date «lu 20e jour «le février 1907, constituant en corporation: Samuel II.Shriar, 2115, rue Yaladc, Saint-Laurent, Murray B.Spiegel, 03, Banstead, Montréal Ouest, tous «leux avocats, et Jovittc B.Dmuchalsky, secrétaire, célibataire, 581, La«louceur, Laval, pour les objets suivants: gret, bursar, all three of Bourg-Royal Avenue ami St-Viateur, Chwlesbourg-East, for tlu following purposes; To assure the physical, intellectual ami moral formation «>f deaf children, under the name (,f \"Institut des Sourds «le Charlcsbourg in«\\\".The amount to which is limited the annual revenue of the immoveable property Which tin-corporation may acquire and possess, is $2111010.The bead office of the corporation is al ('lier.lesbourg-East, judicial «listrict of Quebec.Raymond Doivii i .Assistant Secretary of the Proi 10226 '' Ital Montreal Construction Ltd.Notice Is given that umler Part I \u2022 I the Companies Act.letters patent, bearing date the 201 h day «>f February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: Etiocardo Nobili, 73 St.Zotique Street Fast.Giuseppe Germani, 8160 Papineau, and Violando Lepore, 8160 Pabre, all tint?builders, of Montreal, for the following purpose*: To carry on business as builders and general contractors, under the name of \"Ital Montreal Const ruction Ltd.\", with a total capital stock of 810.000.divided into 2.0(H) common shares of 810 each and 200 preferred shares «»f $100 each.The head office of the company is at s|t;u Fabre Street, Montreal, jmlicial districl of Montreal.Raymond DouVILLK, Assistant Secretary of the Prot 19228-0 696-67 Laboratoire du Dr Renaud (Division Canada) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roch Clouticr, industrialist, Louise (i.Cloutier, housewife, wife separate as to property of said Roch Clouticr, ami duly authorized by him for the presents, both of 884 Monseigneur-Grandin, Sainte-Foy, and Jean-Yves Renaud, accountant, 05 Yalvue Street, Lorettcville.for the following purposes: To «leal in beauty products of all kinds, under the name of \"Laboratoire «lu Dr Renaud (Division Canada) inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares «»f SlOeach.The head office of the company is at 2873 Stc-Foy Road, Sainte-Foy, judicial district of Quebec.Raymond Douvii.i.i Assistant Secretary of the Pfovi 19228 526-07 Laine Longucuil Inc.Notice is given that umler Part I «»l the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of February, 1907, have been issm I by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Samuel H.Shriar, 2445 Yaladc Street Saint-Laurent, Murray B.Spiegel, 03 Banstead, Montreal Watt, both advocates, ami Jovitle B.Dmuchalsky, secretary, spinster, 581 Ladouceur, Laval, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1907, Vol.99, So.15 2497 Exercer lé commerce de toutes sortes de laina-«C, fil, vêtement*: et textiles, sous le nom de r Laine Longueuil Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de si chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacunei I- ûège social de la compagnie est à Mont-réal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228 706-67 To deal in wool, threads, clothing and textiles of all kinds, under the name of \"Laine Lougueuil Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares Of -SI each and 30,000 preferred shares of §1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.19228-0 700-07 Lepra inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneUr de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de février 1907, constituant en corporation: Pierre Laitue, 3031, de la Retraite, Jean Marier, 3045, La Forest, et Jean Richard, 3171, Montpetit, tous trois avocats, de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Exercer le commerce de placement immobilier, tous le nom de « Lepra inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaire d'une valeur nominale de 810 chacune.I.e siège social de la compagnie est 1135, chemin St-Louis, Sillery, district judiciaire de Quebec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228* 818-07 Lepra inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 23rd day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre LaRuc, 3034 de la Retraite, Jean Marier, 3045 La Forest, et Jean Richard, 3471 Montpetit, all three advocates, of Sainte-Foy, for the following purposes: To deal in real estate investments, under the name of \"Lepra inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 4.000 common shares of a nominal value of 810 each.The bead ollice of the company is at 1135 St-Louis Road, Sillery, judicial «listrict of Quebec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.1922S 818-07 Ligne des Propriétaires Quartier St-François Ville Laval St-François City of Laval Home Owners Association Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late du 17e jour «le février 1907, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Therrien, gérant-adjoint, 8400, 5e avenue, Hen.- LeBlanc, commis, 8405, 7c avenue, et Jean-Guy Gaseon, sergent «le police, 3S05, rue Cambrai, tous trois «le Laval, j>our les objets suivants: Etudier les législations intéressant les propriétaires fonciers et promouvoir tous projets (l'amélioration et d'embellissement de leur territoire, sous le nom «le « Ligue des Propriétaires Quartier St-François Ville Laval \u2014 St-François City of Laval Home Owners Association ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et |k)ssé.ler, est «le 810,000.Le siège social «le la corporation est à Laval, 'listrict.judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymoni) DoUville.19228m 048-07 Ligue des Propriétaires (Quartier St-François Ville Laval St-François City of Laval Home Owners Association Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of February, 1967, have l>ecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share eapiral: Gilles Therrien, asso«-iate manager, 8400, 5th Avenue René LeBlanc, clerk, S405, 7th Avenue, and Jean-Guy Gascon, police sergent, 3865 Cambrai Street, all three of Laval, for the following purposes: To study legislations concerning land owners ami to promote all improvement and embellishing projects of their territory, under the name of \"Ligue des Propriétaires Quartier St-Fran«;ois Ville Laval \u2014 St-François City of Laval Home Owners Association\".The amount to which are limited the immoveable properties that the corporation may acquire or possess is $10,000.The hca«l office of the corporation is at Laval, judicial «listrict of Laval.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the Province.19228 04S-07 Les Loisirs de l.ongue-Pointe-de-Mingan, inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late du 20e jour «le février 1907, constituant en corporation sans capital-actions: Hervé Albert, Thommy Vilwrt, tous «leux menuisiers, (ieorges Met hot, marchand général, Clarence Ward, gérant de Caisse populaire, et \\v.ii Loisellc, Opérateur de machinerie, tous (,\"icrt, both joiners, Georges Méthot, general merchant, Clarence Ward, Caisse populaire manager, anrl Yvon Loisellc, operator of machinery, all five of Longue-Pointe, for the following purposes: GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 15 avril 19G7, 99' année, n° 16 2498 Établir h diriger un centre «le loisirs, sous l«- nom «le « Les Loisirs «le Longuc-Pointc-dc-Mingan, inc.», Le montant au«|uel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peu! acquérir et posséder la corporation, est «le 8100,000.Le siègus deux «le Juliette, et Émilc-J.Tabah, comptable, 1030\"), rue Cartier.Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des ateliers et magasins «le vêtements, sous le nom de « Manufacture Alontealm limitée \u2014 Montcalm Manufacture Limite»! », avec un capital total «le 8100.000, divisé en 000 actions onlinaires de 8100 chacune et en 400 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 191, rue Montcalm, Jolictte, «listrict judiciaire de Joliet-te.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.1922S-0 402-07 Motel Le d'Iberville incorporée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late du 1er jour «le février 1907, constituant en corporation: Rémi Vachon, entrepreneur, Anne-Marie Pomerleau, ménagère, épouse séparée de biens «lutlit Rémi Vachon, tous deux «le 7, rue Roy, et Fernaml Vachon, menuisier, 789, chemin Richelieu, tous trois «le Saint-Jean, pour les objets suivants: Exercer le commerce de prêteur d'argent, de compagnie «le construction, «le placement et de portefeuille (holding), ainsi que le commerce de To establish and «lirect a recreational center, umler the name of \"Les Loisirs «le Longue.I\\>intc-«lc-Mingan, inc.\".The amount to which the value «>f the imuio.vable property which the corporation may sc.quire and hold is to be limited, is $100,000.' The head office of the corporation is at Longue, l'ointe, judicial district of Hauterive.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Prat i.10228 \\Ul Madroni Inc.Notice is given that under Part I ol (he Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Max S.Kaufman, f>74 Clareiuont, Westmount, J.Roy Hoffman, 5015 Pinedale, Côte Saint-Luc, both advocates and Queen's Counsels, ami Oscar Respitz, advocate, 4945 Glencairn, Montreal, for the following purposes: To «leal in suede and leather coats, jackets, hats, wearing apparel, footwear, products, novelties of every kind ami description, umler the name of \"Madroni Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Province.19228-0 79647 Manufacture Montcalm limitée Montcalm Manufacture Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Tabah, manufacturer, 101 Tcllier Street, Theo Kershch, production manager, 131 St-Paul Street, both of Juliette, nad Emile-J.Tabah, accountant, 10305 (ailier Street, Montreal, for the following purposes: To operate clothing workshops and stores, unde rthe name of \"Manufacture Montcalm limitée \u2014 Alontealm Manufacture Limited\", with a total capital stock of 8100,000.divided into 000 common shares of $100 each and i1\"1 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 191 Montcalm Street, Joliette, judicial districl f Joliette.Raymond Dou villi Assistant Secretary of the Province.1922S i''-1'1\" Motel Le d'Iberville incorporée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 1st day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rémi Vachon, contractor, Anne* Marie Pomerleau, housewife, wife separate as to property of the said Rémi Vachon, both of 7 Roy Street, and Fernand Vachon, joiner.789 Richelieu Road, all three of Saint-Jean, for the following purposes: To carry on the business of money lender, of construction, investment and holding company and to act as restaurateurs, under the name ffl QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, J9G7, Vol.99, No.15 2400 rcsl.niialfiirs, sous le nom de « Motel Le d'Iher-incorporée », avec un eapital total de 575,0 H.divisé en 900 actions ordinaires de 8100 chacune el eu 250 actions privilégiées de 8100 chacune.I.c siège social de la compagnie est 7, rue Roy, Saiul-lea\", district judiciaire dThcrville.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.10228-0 247-07 Nomar Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1907, constituant en corporation: David Fleming, avocat, 65, chemin Belvédère, Westmount, Clinton C.Casselman, comptable, Sainte-Adèle, et Cécile Dufresne, secrétaire, célibataire, 7723, 22e avenue.Saint-Michel, pour les objets suivants: Exercer un commerce de finance, de placements et de courtage, sous le nom de « Nomar Investments Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de SI chacune.Le siège social «le la compagnie est 1255, rue University, suite 1200, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.1022S 413-07 \"Motel Le d'Iberville incorporée\", with a total capital stock of 875,000, «livided into 500 com- moii shares of $100 each and 250 preferred shares of $100 each.The head ofliee of the company is at 7 Roy Street, Saint-Jean, judicial district of Iberville, Raymond Dou villi:, Assistant Secretarij of the Province.1922* 247-07 Nomar Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 30th day of January, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: David Fleming, advocate, 05 Belvedere Road.Westmount.Clinton C.Casselman, accountant, Sainte-Adèle, and Cécile Dufresne, secretary, spinster, 7723, 22nd Avenue, Saint-Michel, for the following purposes: To carry on a general financial, investment and brokerage business, under the name of \"Nomar Investments Inc.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head ollice of the company is at 1255 University Street, Suite 1200, Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.19228-o 413-07 O.T.J, de Pointe-au-Père inc.O.T.J, de Pointe-au-Père inc.Axis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouveraeur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 13e jour «le février 1907, constituant en corporation sans capital-actions: Oméril Duchesne, inspecteur municipal, Philippe Banville, gérant, Rosario Lévesquc, contrôleur, Lucien lllauchet, comptable, et Gérald Drewitt, comptable agrée, tous cinq «le Sainte-Anne-dc-la-Pointe-au-Père, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de O.T.J.«le Pointe-au-Père inc.» .Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est «le 8100,000.Le siège social «le la corporation est à Sainte-Aiuk -tle-la-Pointe-au-Père, district judiciaire «le Rimouski.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228-0 595-07 André Page inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 14e jour «le février 1907, constituant en corporation: Clau«le-E.Leduc, '\".), avenue Beverley, Jean Lefrançois, 51, Roosevelt, tous deux avocats, de Mont-Royal, >'t Mariette Dupré, secrétaire, fille majeure, 0550, lue avenue, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, auberges et restaurants, sous le nom de « André Page inc.», avec U|i capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires «l'une valeur nominale de S10 chacune et en 350 actions privilégiées d'une valeur nominate de S100 chacune.Notice is given that umler Part III of the Companies Act, letters patent, Iwaring «late the 13th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without sliare capital: Oméril Duchesne, municipal inspector, Philippe Ranville, manager, Rosario Lévesquc, comptroller.Lucien Blauchet, accountant, and Gerald Drcwitt, chartere«l accountant, all five of Sainte-Annc-dc-la-Pointe-au-Père, for the following purposes: The organization of recreational facilities, under the name of \"O.T.J.«le Pointe-au-Père inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire an«l hold is to be limited, is $100,000.The head ollice of the corporation is at Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père, judicial district of Rimouski.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.19228 ( 595-07 André Page inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 14th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claude-IE, Leduc, 105 Beverley Ave., Jean Lefrançois, 51 Roosevelt, l>otli advocates, of Mount Royal, and Mariette Dupré, secretary, fille majeure, 6550,19th Ave., Montreal, for the following purposes: To operate hotels, motels, inns ami restaurants, under the name of \"André Page inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a nominal value of $10 each and 350 preferred shares of a nominal value of $100 each. 2500 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, It avril 2967, 99' année, n° 15 Le siège social «le la compagnie est route 80, aforin Height*, district ju lunaire «le Terrebonne.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douviiab.10228-0 023-07 The head office of the company is at route 30 Mm in Heights, judicial «listrict of Tend nunc, Raymond Douvii.i.i;.Assistant Secretary of the PrOi i tee.1922S 0234» Pierre Racine Snack Bar Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le liculcuant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentee, en ilalc «lu 3e jour «le février 1007, constituant en corporation: Sydney Laaarovitz, 084, M«ml Sl-Dcnis, Sillery, Jules Bernatchez, 8170, De Vienne, Charlcsbourg.et Jean McNi-coll, 2880, Gregg, Sainte-Foy, tous trois avocats, pour les objets suivants: Paire affaires comme restaurateurs, sous le nom «le « Pierre Rai inc Snack Bar Inc.», avec un capital total «le S 10,000, divisé en 2.000 actions ordinaires «le 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le liège social «le la compagnie est à Québec, «li>trict judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10228-O 658-67 Pierre Racine Snuck Bar Inc.Notice is given that umler Part I «)f th.Ce».panics Act, letters patent, hearing «lat«- the 3rd day of February, 1007, have Ween Issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpo.rating: Sydney Lazarovitz, 084 Mont Si-Denis, Sillery, Jules Bernatchez, S170 De Vienne, Charlcsbourg, ami Jean McNicoll, 2529 Gregg, Sainte-Foy, all three lawyers, for the following pur posas: To carry on business as restaurant ki eperi, umler the name of \"Pierre Racine Snuck Oar Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares «)f 8ID each ami into 200 preferred shares of $100 each.The head «)!lif a nominal value of $10 each.The head office of the eompany is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province, 19228 1153-67 Rebec Construction Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé «les lettres patentes, en «late «lu 20e jour «le janvier 1907, constituant en corporation: Rosaire Bouffant, marchand, Agnès llergcron, ménagère, épouse dudit Rosaire Bouffard, tous «leux de route rurale # 1, Black Lake, et François Cailloux, vendeur, 1585, boulevar«l Sainte-Croix, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire nll'aires comme une compagnie «le construction et exercer le commerce de matériaux «le construction, sous le nom «le « Rcbcc Construction Inc.», avec un capital total de 810,000, divisé en 4,000 actions ordinaires «le $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228 5085-66 Rebcc Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Com-panies Act, letters patent, bearing «late the 20» day of January, 19(57, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rosaire Bouffard, merchant, Agnès Bergeron, housewife, wife of the sai«l Rosaiiv Bouffard, both of Rural Route f 1, Black Lake, and François Cailloux, salesman, 1585 Sainte-' 'rOB Boulevard, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the business of a construction company and to deal in building materials, under the name of \"Rebec Construction !»«'\u2022 \u2022 with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each ami 3,600 preferred shares of $10 each.The head offi«?e of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.19228-o 50850*6 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1907, Vol.99, No.15 2501 Itlllutllll Inc.\\m est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en «late «lu 15e jour «le février 1907, constituant en corporation: Anne (îoldenberg, lisl.'» ouest, rue Sherbrooke, app.«S, Thérèse i', , .nil.10430, André-Jobin, app.2, tous «leux ,|, Montréal, et Lise Wulton, 14, rue Demuy, Onu.'hei ville, toutes trois secrétaire, filles majeures et usant «le leurs «Iroits, {>our les objets suivants: Kxcrcer !«' commerce «l'une compagnie «le portefeuille et de placements, sous le nom «le Robann Inc.», avec un capital total «le 8100,000 divisé en Kit) actions ordinaires «l'une valeur au pair de S10 chacune et 99,000 actions privilé-giées d'une valeur au pair de $1 chacune.I.' siège social «le la compagnie est 22.avenue Franklin, Mont Royal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-.secrétairc de la province, Raymond Douville.19228 053-07 Rotary Club of Montreal-Lakeshore Avis est «humé qu'en vertu de la troisième partir de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en date «lu 31e jour «le janvier 1967, constituant en corporation sans capital-actions: Jack (i.Mclntyre, officier «le fiducie, 15205, rue Théorêt, Sainte-Geneviève, James McDer-Hiott, pharmacien, 2305, Lakeshore Drive, Prank S.Brophy, comptable agréé, 85, Brook-liaveu.tous deux «le Dorval, David Green, 124, avenu, de Breslay, John D.McAnulty, 01, Chester, Martial Clermont, 29, avenue Victoria, Herbert -L Cunningham, 03, avenue Vincennes, tous quatre administrateurs, Robert Stricklaml, 23, chemin Lakeshore, Allan R.Capcl, 122, avenue Broadview, tous «leux ingénieurs professionnels, Richard R.Davis, photographe professionnel, 78, chemin Ladeshore, Klaus Schirow, pépiniériste, 4, Clearvicw Crescent, Stanley F.Wade, courtier en assurance, 202, chemin Ladeshore, tous les neuf «le Pointe-Claire, A.Lome Havanl, 47, chemin Apple Hill, Baic-¦11 rfé, Howard Joyce, 258, chemin Lakeshore, tous deux administrateurs, et Hollett P.Kelley, expert en publicité, 75, Gables Court, ces deux derniers de Beaconsfieltl, pour les objets suivants: Entreprendre exclusivement telles organisa-lion-' charitables jugées rccommamlables par la corporation, sous le nom de « Rotary Club of Montreal-Lakeshore ».le Montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut pos-séder ou détenir, est «le SIOO.000.Le siège social «le la corporation est 352, avenue Dorval.Dorval, district jmliciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de Ut province, Raymond Douville.19228 414-07 Rotary Club of Montreal-Lakeshore Foundation Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieu tenant.-gouverneur «le la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 31e jour de janvier 1967, eonsliluant en corporation sans capital-actions: 'T\u2022 ^c'*\"tyre, officier de fiducie, 15205, rue théorêt, Sainte-Geneviève, James McDermott, Robann Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 15th day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor if the Province, incorporating: Anne Goldenlierg, 0815 Sherbrooke Street West, Apt.8, Thérèse Perreault, 10430 André-Jobin, Apt.2, both of Montreal, ami Lise Walton, 14 Demuy Street, Boucherville, all three secretaries, filles majeures et usant «le leurs droits, for the following purposes: To carry on the business of a holding anil investment company, under the name of \"Robann Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 100 common shares of the par value of $10 each and 99,000 preferreil shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 22 Franklin Avenue, Mount Royal, judicial district of Montreal.raymond Dot \"ville, Assistant Secretary of the Province.1022S-o 653-07 Rotary Club of Montreal-Lakeshore Notice is given that under HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of January, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jack G.Mclntyre, trust officer, 15205 Théorêt Street, Sainte-Geneviève, James McDermott, pharmacist.2305 Lakeshore Drive, Frank S.Brophy, cliartcrcd accountant, 85 Brookhavcn, both of Dorval, David Green, 124 «le Breslay Avenue, John D.McAnulty, 01 Chester, Martial Clermont, 29 Victoria Avenue, Herbert J.Cunningham, 03 Vincenncs Avenue, all four executives, Robert Stricklaml, 23 Lakeshore Road, Allan R.Capcl, 122 Broadview Avenue, both porfessional engineers, Richard R.Davis, professionnel photographer, 78 Lakeshore Road, Klaus Schirow, nurseryman, 4 Clearview Crest-cent, Stanley F.Wade, insurance broker, 202 Lakeshore Road, all nine of Pointe-Claire, A.Lome Havanl, 47 Apple Hill Road, Baie-d'Urfé, Howard Joyce, 258 Lakeshore Road, both executives, ami Hollett P.Kelley, advertising expert, 75 Gables Court, the latter two of Béa* consfield, for the following purposes: To engage exclusively in such charitable undertakings as may be deemed advisable by the corporation, under the name of \"Rotary Club of Montreal-Lakeshore\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may own or hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation is at 352 Dorval Avenue, Dorval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.19228-o 414-67 Rotary Club of Montreal-Lakeshore Foundation Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, hearing date the 31st day of January, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jack G.Mclntyre, trust officer, 15205 Théorêt Street, Sainte-Geneviève, James McDermott, 2502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, lô avril 1967, 99' année, ii° 15 pharmacien, 2305, Lakeshore Drive, Frank S.Brnphy.comptable, agréé, 85, Brookhaven, tous deux de Dorval, David Green, 124, avenue de Breslay.John D.McAnulty, 81, Chester, Martial Clermont, 2'.).avenue Victoria, Herbert J.Cunningham, 03, avenue Yinccnncs, tous quatre administrateurs, Robert Strickland, 23, chemin Lakeshore, Allan R.Caoel, 122, avenue Broadview, tous deux ingénieurs professionnels, Richard 1t.Davis, photographe professionnel, 78, chemin Lakeshore, Klaus Schirow, pépiniériste, 4, Clear-view Crescent, Stanley F.Wa«le, courtier en assurance, 202.chemin Lakeshore, tous les neuf de Pointe-Claire, A.Lome Bavard, 47, chemin Apple II ill.Baic-dTifé, Howard Joyce, 258, chemin Lakeshore, tous deux administrateurs, «d Ilollell P.K'ellcy, expert en publicité, 75, Cables Court, ces «leux «lerniers «le Reaconsfield, pour les objets suivants: Entreprendre exclusivement telles organisations charitables jugées rceommaudahlcs par la corporation, sous le nom «le « Rotary Club of .Montreal-Lakeshore Foundation .Ia' montant auquel la valeur «les biens immobiliers «pu* la corporation peut posséder ou détenir, est de $100,000.Le siège social de la corporation est 353, avenue Dorval.Dorval.district judiciaire «le Montréal.l.v Sous-secrétaire de la province, Raymond Dor ville.10228 415-07 pharmacist, 2305 Lakeshore Drive, Frank S.Ilrophy, chartered accountant, 85 Brookhavm.both of Dorval, David Green, 124 «le Ibeslay Avenue, John D.McAnulty, 01 Chester, Martial Clermont, 29 Victoria Avenue, Herbert, J.Cunningham, 03 Yinccnncs Avenue, all four executives, Robert Strickland, 23 Lakcghorc Road, Allan Et.Cape!, 122 Broadview Avenue, both professional engineers, Richard R.Davû, professional phot«>grapher, 78 Lakeshore Road, Klaus Schirow, nurseryman, 4 Clcarview Cm.cent.Stanley F.Wade, insurance broker, Joj Lakeshore Road, all nine «>f Pointe-Claire.A.Lorne Havard.47 Apple Hill Road, Baie dl'rf,'., Howard Joyce, 25S Lakeshore Roa«l, both executives, and Ilollett P.Kelley, advertising expert, 75 Gables Court, the latter two of Beaconsfield, for the following purposes: To engage exclusively in such charitable under-takings as may l>e «Ieemeil advisable by the corporation, umler the name «>f \"Rotary Club of Montreal-Lakeshore Foundation\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may own «>r hold is to be limited, is $100,000.The head ollice of the corporation is at 3S2 Dorval Avenue.Dorval, judicial district oi Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.19228-0 115-67 La Société Canadienne de l'ouïe du Québec The Canadian Hearing Society of Quebec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en «late du 24c jour «le janvier 1907, constituant en corporation sans capital-actions: William Wallace Barrett, avocat, 22, Edgar Avenue, Toronto, province «l'Ontario, Mary Bridge, rédactrice, fille majeure, 1321, boulevanl Graham, app* 8, Mont-Royal, Mary Buxton-Hobnes, ménagère, épouse séparée de biens «le Rol)ert CardoBO, 035, Grosvenor, Lorna Gihlay, ménagère, veuve «le feu Walter Harold Sparrow, 480, avenue Mountain, toutes deux de West-mount, Jean-Louis Doucet, directeur, 235, rue Sherbrooke ouest.Augusta Van Puyenbroek, ménagère, épouse séparée «le biens «le Joseph-Auguste Gosselin, 5047, rue Wilderton, Révérend Père Paul Leboeuf, 3725.rue St-Denis, Révérend Frère Hervé Neveu, 7400, l>oulcvard St-Laurent, tous deux professeurs, Lloyd Arnold McClintock, surintendant, 5150, avenue Belmore.Bertrand Primcau.directeur médical, 4470, rue Laeomhc, Edward Henri Robitaille, gérant, 3480, avenue Trenholmc, tous sept «le Montréal, Daniel Ling, directeur, 09, rue Nelson, Montréal-Ouest, Henry M into, directeur, 59, Bittel, Lorraine, Robert Prcnovost, gérant «les ventes, 470, avenue Mercillc, St-Lambert, et Ina Young, secrétaire, fille majeure.5280, avenue Durocher, Outremont, pour les objets suivants: Promouvoir et développer «les mesures et «les programmes pour le traitement, l'assistance et le bien-être dés personnes souffrant de surdité, sous le nom «le « La Société Canadienne de l'ouïe «lu Québec - The Canadian Hearing Society of Quebec\".Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $100.000.La Société Canadienne de Fouie du Québec The Canadian Hearing Society of Quebec Notice is given that umler Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of January, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: William Wallace Barrett, lawyer, 22 Edgar Avenue, Toronto, Province of Ontario, Mary Bridge, writer, fille majeure, 1321 Graham Boulevard, Apt.8, Blount Royal, Mary Buxton-Holmes, housewife, wife separate as to property of Robert Cardoso, 035 Grosvenor, Lorna I iihlay.housewife, widow of the late Walter HaroM Sparrow, 4X0 Mountain Avenue, both of West mount, Jean-Louis Doucet, director, 235 Sherbrooke Street West, Augusta Van Puyenbroek, housewife, wife separate as to property of Joseph Auguste Gosselin, 5047 Wilderton Street.Reverend Father Paul Lebocuf, 3725 St-Denis Street, Revereml Brother Hervé Neveu.7400 St-Laurent Boulevanl, both professors, Lloyd Arnold McClintock, superintendent, 5150 Belmore Avenue, Bertrand Primcau, medical «li; rector, 4470 Lacombe Street, Edward Henri Robitaille, manager, 3480 Trenholmc Avenue, all seven of Montreal, Daniel Ling, director, 88 Nelson Street, Montreal-West, Henry M into, «lirector, 59 Bittel, Lorraine, Robert Prenovost, sales manager, 470 Mcrcille Avenue, St-Lauibert, and Ina Young, secretary, fille majeur»-.5280 Durocher Avenue.Outremont, for the following purposes: To promote ami develop measures and programs for the treatment, assistance ami welfare of those suffering from deafness, umler the name of \"La Société Canailiennc «le l'ouïe «lu Québec ~ The Canadian Hearing Society of Quebec \u2022 The amount to which is limited the immoveable property which the corporation may acquire ami possess, is $100,000. QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 15, 1907, Vol.99, No.15 2503 I., liège social oratc a corporation without share capital.Father Gilles Boulet, priest, 400 Bonaventure St., Jean-Guy Béliveau, 2731 La Jonquièrc.Bernard Lorrain, 3910 «le la Sapinière, ami Amlré Brousseau, 1871 Père-Daniel, the latter three administrators, all four of Trois-Rivières, for the following purposes! To group together the persons interested in the science of archaeology, and to promote their knowledge in the practice of this science, umler the name of \"La Société d'archéologie «le Trois-Rivières\".The amount to which the annual income from the immoveable property which the corporation may acquire ami hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at 486 Bonaventure St., Trois-Rivières, judicial «listrict of Trois-Rivières.Raymond Douville, Assistant Seeretari/ of the Province.1922S 775-67 Station de service Lasalle inc.Lasalle Service Station Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a acconlé «les lettres patentes, en «late «lu 10e jour «le février 1907, constituant en corporation: Antoine Paré, 1115, Sherbrooke ouest, John Archambault, 5724, Déon, tous deux «le Montréal, et Alphonse Bar-Uan.s 17, Dunlop, Outremont, tous trois avocats, pair les objets suivants: Exploiter «les postes de service, «les postes il essence, «les parcs de stationnement et construction» de toutes sortes, sous le nom de « Station de ki vice Lasalle inc.\u2014 Lasalle Service Station Inc.avec un capital divisé en 340 actions ordinaire» sans valeur nominale et en 600 actions privillgiées «le $10 chacune.Le mène social de la compagnie est à Montréal, districl judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228m 493-07 Station de service Lasalle lue.Lasalle Service Station Inc.Notice is given tliat under Part I of the ( '«»ui-panies Act, letters patent, bearing «late the 10th day of February, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antoine Paré, 1115 Sherbrooke West, John Archambault, 5724 Déoin, both of Montreal, and Alphonse Barbeau, 847 Dunlop, Outremont, all three advocates, for the following purposes: To operate service stations, gas stations, parking lots and buildings of all kinds, under the name of \"Station de service Lasalle inc.- - Lasalle Service Station Inc.\", with a capital-stock divided into 340 common shares without nominal value and 000 prefer ret! shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymon d Dou ville, Assistant Secretary of the Province.19228 493-07 Super Marché Guizot inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouvemeur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de février 1907, constituant en corporation: André Perreault, WS0, Montclair, Normand Duval, 2185, Nicolas-Perrot, tous «leux avocats, et Raymondc La-ijiarelie, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, 8832, St-Denis, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme épiciers, sous le nom de Super Marché Guizot inc.», avec un capital total ,le 800,000, divisé en 4.000 actions ordinaire de 810 chacune et en 2,000 étions privilégiées de 810 chacune.Super Marché Guizot inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 28th day of February, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Province, incorporating: André Perreault, 4080 Montclair, Normand Duval, 2185 Nicolas-Perrot, both lawyers, an«l Raymondc Lamarchc, secretary, fille majeure using her rights, 8832 St-Denis, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Super Marché Guizot inc.\", with a total capital stock of $00.000, divided into 4,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each. 2504 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 avril 1907, 99' année, nu lô lx' .siège sueiul tie lu compagnie est 550, rue Guizot est, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228-0 710-117 T.M.Paysagistes inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «!«¦ la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur «li- la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 22e jour de février 1907, constituant eu corporation: Jcan-l'aul Taillefer, 0220.29e avenue.Mirald Millette, 8904, boulevard Arthur-Sauvé, tous deux paysagistes, de Laval, et Yvon Leroux, comptable, 1S3, 7e avenue.Saint-Kustachc, pour les objets suivants: Faire alfaires comme paysagistes, sous le nom de « T.M.Paysagistes inc.avec un capital total «le $40,000.«livisé en 3.000 actions ordinaires «le $10 chacune «t en l.OOO actions privilégiées «le $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Laval, «listrict judiciaire «le ont real.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville.I022S-o 547-07 Terrasse Thérèse inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a acconlé des lettres patentes, en «late du Se jour de mars 1907, constituant en corporation : David Housefather, notaire.0280, place Northcrcst, app.1019, Lauréanne Geoff rion, secrétaire, épouse séparée «le biens «le Gilles Larivée, 0086, rue St-Hubert, et Sundra Frcc«lman.secrétaire, célibataire, 4575, rue Michel-Rihuud, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires «l'une compagnie «le construction et d'immeubles, sous le nom «le « Terrasse Thérèse inc.», avec un capital total «le $40,000, «livisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social «le lu compagnie est 3650, rue Mountain, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228 1008-67 Gilbert Timm construction inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a acconlé des lettres patentes, en date du 21e jour de février 1967, constituant en corporation: Gilbert Timm, technicien, Yictoire Cossette, ménagère, épouse eontraetuellement séparée de biens dudit Gilbert Timm, tous deux de 842, Perrier, Brossanl, et Claude Cossette, menuisier, 10105, Lille, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom «le « Gilbert Timm construction inc.», avec un capital total de $5,000, divisé en 150 actions ordinaires de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 842, Perrier.Brossanl, district judiciaire de Montréal.Le Sous secrétaire de la province, Raymond Douville.19228-o 698-67 The bead office of the company b 1 g&fl Gui/.ot Street Hast, Montreal, judicial (listrki of Montreal.Raymond Doi vu Assistant Seeretari/ of the Proi et, 19228 \" : T.M.Paysagiste* in«'.Notice is given that umler Part I of the Companies Act.letters patent, licariri: date the 22ml day «>f February.1967, have been issued by the Lieutenant-Governor «>f the Prima*, incorporating: .lean-Paul Taillefer, 0220 29th Avenue, Mirahl Millette.8204 Ailliu -Sauve\" Boulevard, both landscape gardeners of I.aval, and Yvon Leroux, accountant, 183, 7tb Avenue, Saint-Eustache, for the following purposes: To carry on business as landscape garclenen, umler the name of \"T.M.Paysagistes inc.\" with a total capital stock «»î 810.000.iividi-d into 3,000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of 8IX) each.The head f the Mining Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21th day 84,000,000, the additional capital stock being divided into 3,960,000 shares of -Si each.Raymon d I)i\" vims, Assistant Secretary of the Province.1922S-o 5397-66 -1360/18 Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 683 Québec, le 15 mars 1967.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Co\\« r.knant le règlement sur les aliments.Ii.est ordonné, sur la proposition «lu Ministre de l'agriculture et «le la colonisation: Que, sous l'autorité «les articles 3, 6 et 7 «le la Loi des produits agricoles et «les aliments (Statuts refondus.1964, cliapitre 119), soit édicté le règlement, dont texte ci-joint, intitulé: « Règlement sur les aliments *, (!opie ««informe.Le Greffier du Conseil Exécutif, Jacques Puémont.ItÈGLEMENT SIR LES ALIMENTS.Titre Ieh.\u2014Dispositions générales.Section I.\u2014Application.Art.1er.-Le présent règlement a pour but de réglementer, sous le régime de la Loi «les produits agricoles et «les aliments, la production et.la vente des aliments.Le mot « ministre », dans le présent règlement, désigne le ministre «le l'agriculture et de la colonisation* Art 2.-Il est interdit «le détenir, de préparer ou d'acheter en vue «le la vente, de mettre en vente nu en dépôt ou «le vendre dans un lieu quelconque, de servir dans un lieu de consommât ion.de transporter, «le faire transporter ou d accepter pour une destination quelconque, dans les limites de la province, un aliment impropre à la consommation ou qui ne répond pas aux conditions de salubrité, «le qualité, «le conditionnement ou autres prévues ci-après.Section II.\u2014Règles sanitaires.An.:;.Tout produit destiné à l'alimentation ou a la production ou préparation d'aliments doit être sain et de provenance saine, convenir parfaitement à sa destination et répondre à toutes les données de l'hygiène alimentaire.Il ne doit présenter aucun caractère physique, chimique ou biologique anormal, ni avoir aucun goût, arôme ou aspect anormal, ni contenir aucun élément étranger à sa composition, im- Ordcr in Council Executive Council Chamber Number 683 Québec, March 15.1907.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning Food Regulations.It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Agriculture ami Cohini/ation: That, umler the authority of sections 3, 6 ami 7 of the Agricultural Products ami Food Act (Revised Statutes, 1004, chapter 119), be enacted the regulations, copy of which is hereto attached, entitled: \"Food Regulations\".True copy.Jacques Pkémont, Clerk of the Executive Council.FOOD REGULATIONS.Part I.\u2014General Provisions.Division I.- Application.Art.1.- The purpose of these regulations is t«> regulate the production and sale of food umler the provisions of the Agricultural Products and Pood Act.In these regulations, the won! \"Minister\" means the Minister of Agriculture ami Colonisation.Art.2.\u2014It is forbidden to bold, prepare or purchase for sale, to place for sale or on deposit, or to sell in any place whatever, to serve in any place of consumption, or to convey or cause t«> lie conveyed or accept for any destination within the Province, any food that is unfit for consumption or which «locs not meet the requirements as to wholesomcness, quality, conditioning or other requirements hereinafter specified.Division II.- Hygienic Requirements.Art.3.\u2014All products intended for food or the production or preparation of food must he wholesome and derived from a wholesome source, be perfectly suite«l to their purpose ami fully conform to all the requirements of foo«l hygiene.They must be free from physical, chemical ami biological abnormalities and from abnormal flavours, odours or appearance, and from any extraneous substance or any substance which is 2508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 15 avril 1907, 99' année, n° 15 propre à l'alimentât ion ou nuisible à la santé de l'homme ou des animaux.Il doit être soustrait à tout contact ou voisinage nocif et être constamment à l'abri de toute cause de pollut ion ou de contamination et de toute cause susceptible d'en compromettre la qualité.Art.4.Le produit doit être maintenu à une température propre à en assurer la conservation.Ix' produit altérable à la chaleur doit être refroidi sans redard et maintenu constamment à une température ne dépassant pas 50° Fahrenheit jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pOttr l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température.Dans le cas d'un produit congelé, la tempéra-turc doit être inférieure au point de congélation du produit et non supérieure à celle prévue par l'industrie de la congélation.Dans le cas d'un produit non congelé, la température doit être supérieure au point, de congélation du produit.Art.5.-La production, la préparation, la conservation, le conditionnement, la manutention et le transport du produit doivent être effectués dans des conditions de propreté et d'hygiène irréprochables et tie façon à assurer la pleine valeur alimentaire, hygiénique et commerciale du produit.Art.G.\u2014Nul ne peut procéder aux opérations visées à l'article 5, ni avoir accès à un lieu, local OU véhicule OÙ s'exercent ces Opérations ou qui contient ou est destiné à contenir le produit, à moins d'être en parfait état sanitaire et en parfait état de propreté corporelle et vestimentaire et de ne présenter aucune plaie ou affection externe ni aucun danger de contamination.Art.7.\u2014Le matériel utilisé doit présenter pleine garantie tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue technique.Il doit être maintenu propre et en parfait état et ne doit servir qu'à cet usage.La même règle s'applique à tout lieu, local, installation, véhicule, objet, produit ou matériau utilisé.Section III.\u2014Fraudes et infractions.Art.8.\u2014Est prohibée toute tromperie ou tentative de tromperie, toute déclaration ou indication fausse, inexacte ou trompeuse, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit: 1° sur la nature, l'état, la composition, l'identité, la provenance, l'origine, l'utilisation, la destination, la qualité, la quantité, la valeur, le prix ou une particularité du produit; 2° sur le lieu, la date ou les procédés de préparation, fabrication, conservation ou conditionnement du produit; 3° sur le mode d'emploi ou de conservation du produit; 4° sur l'identité, les qualités ou aptitudes du producteur, préparateur, fabricant, conserveur, conditionneur, distributeur ou de l'agent de vente ou de livraison du produit.Art.9.\u2014Est prohibée toute falsification ou tentative de falsification du produit, toute modification frauduleuse de la composition, de la qualité ou de la quantité du produit, toute opération ou manoeuvre tendant à masquer la mauvaise qualité du produit, à le présenter sous une apparence trompeuse ou ù fausser le résultat du pesage, mesurage, dosage ou de l'analyse du produit, de même que toute indication fraudulcu- uufit for consumption or detrimental to the health of man or animals.They must not l>e allowed to come into contact with or near any harmful substance and must at all times be kept away from anything which might pollute or contaminate them or impair their quality.Art.The aforesaid products must I» kept at a temperature calculated to ensure th, ir pre.servation.Products subject to deterioration by heal must be cooled without delay and kept constantly at a temperature not exceeding 50° Fahrenheit until delivered to the consumer except during the time needed for processing or for a treatment, recognized in the food industry, requiring a higher temperature.Frozen products must be kept at a temperature below their freezing point ami not higher than that prescribed by the frozen food industry.Non-frozen products must be kept abovi their freezing point.Art.5.-The production, processing, preservation, conditioning, handling and transport of the products must be carried out under faultlessly clean ami hygienic conditions and in such a way as to ensure the maximum nutritional, hygienic, ami commercial value of the products.Art.6.\u2014No person shall engage in the operations referred to in artiele 5, nor have access t» a place, premises or vehicle where they art-carried out or which contains or is intended to contain the products, who is not perfectly healthy ami clean, both in person and clotlling, and free from any external sore, ailment, Of potential source of contamination.Art.7.\u2014The equipment used must have all the necessary sanitary and technical safeguards, It must be kept clean and in perfect condition ami must not \\>e used for any other purpose.This regulation also applies to all places, premises, installations, vehicles, object-, products or materials used.Division III.\u2014Fraud and Infringements.Art.8.\u2014All deception or attempt to deceive, or false, inaccurate or deceitful statements r indications, in any manner or form, arc forbidden, as regards: 1.the nature, condition, composition, identity, source, origin, use, purpose, quality, quantity, value, price or other particulars of the product : 2.the place, date or processes of préparai inn, manufacture, preservation, or conditioning of UK product; 3.the directions for using or conserving the product; 4.the identity, qualifications or capabilities of the producer, processor, manufacturer, preserver, conditioner or distributor of the product, or ol the agent who sells or delivers it.Art.9.\u2014It is likewise forbidden to adulterate or attempt to adulterate a product in any manner, or in any way to fraudulently interfere with it3 composition, quality, or quantity, or to make use of any operation or process tending to conceal poor quality or present the product Under a false appearance or to falsify or misrepresent the results of weighings, measurements, or quanti' tativc and qualitative analyses of the product, or QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1907, Vol.99, No.16 2609 M.d n.lant à faire croire a une opération exacte on à un contrôle officiel qui n'a pas eu lieu.I -i également prohibée la détention ou la vente, OU la mise en vente ou en circulation, de moveiis propres à effectuer telle falsification, modification, opération, manoeuvre ou indication.Vit.10.' Commet une infraction quiconque sciemment vend ou livre, ou met en vente ou «\u2022a circulation, un produit soumis ù une opération ou manoeuvre frauduleuse quelconque ou portant une indication fausse, inexacte ou trompeuse, ou en est trouvé détenteur dans ses locaux ou véhicules commerciaux.Art.11.Commet une infraction quiconque, par lui-même ou par une personne à son emploi on agissant sous son autorité, viole une disposition du présent règlement ou consent, incite ou participe à celte violation.Titre II.- -Ln:rx, opérations, vkiiicilks.Section I.\u2014Ateliers et autres lieux.Art.12.-Tout atelier «le préparation OU «le con litionnement d'aliments, «l'abattage ou «l'é-quarrissage d'animaux, doit être situé dans un nte exempt d'odeurs fortes ou nsuaffahondrii et ¦ le toute cause «le pollution et être muni d'un réseau d'évacuation «le ses eaux résiduaires adéquat et en parfait état «l'entretien et «le fonctionnement.Les alentours doivent être bien drainés et rester constamment en Ikmi état de propreté et «le salubrité.Ils ne doivent présenter aucun «langer d'ordre unitaire.Art.13.-L'atelier «loit être assez spacieux pour faciliter les opérations.Il «loit disposer «le locaux «t de moyens suffisants pour répondre aux lins de sa destination.II doit être bien éclairé, aéré et ventilé et avoir une abondante alimentation en eau potable et d'une excellente qualité bactériologique et chimique.Il doit assurer une protection parfaite contre les insectes, rongeurs ou autres animaux et contre toute cause de pollution ou «le contamination.Art.I 1.-Le sol et les murs doivent être constitués ou revêtus «le matériaux résistants, imperméables et à surface lisse.le sol, le plafond, les murs et tout le matériel ou autre installation doivent être faciles à nettoyer et être tenus en parfait état «l'entretien, de propreté et «le salubrité.Art.lô.\u2014L'organisation matérielle de l'atelier, l'aménagement et l'entretien sanitaire «le ses locaux, machines, ustensiles et accessoires, «le même que le mode et les procédés «l'exécution des opérations, doivent répondre aux règles de I art et de l'hygiène et à toute directive que le ministre peut juger à propos de donner dans I intérêt «le la santé publique ou pour assurer le respect «le la l«n et «les règlements.Ail.lu.\u2014Les règles relatives aux ateliers ^appliquent également aux lieux de commerce ou ue consommauon d'aliments et aux locaux conte-Kimt ou destinés à contenir des uliments.tea lieux «le provenance ou «le détention d'animaux ou autres produits destinés à la production « aliments doivent être tenus dans «les conditions de propreté et d'hygiène irréprochables.to make use of any fraudulent or misleading indication tending to give the impression of a precise operation or official control which has not actually taken place.The possession, sale, placing f«»r sale or in circulation «>f means suited to such adulteration, interference, operation, process Of indication are also prohibited.Art.10.\u2014Is guilty of an infringement whosoever knowingly sells, places f«>r sale or in circulation, r delivers a product which has been submitted t«> any fraudulent operation or process or bears a false, inaccurate, «»r deceitful indication, or is found t«> have such a product in his possession on his commercial premises or vehicles.Art.11.\u2014Is guilty of an infringement whosoever, either personally or through a person in his employment or acting under his authority, violates a provision «>f these regulations or incites or consents to or participates in such violation.Taut IL\u2014 Phemises, operations, Vehicles.Division I.\u2014Plants and Premises.Art.12.\u2014Every plant where food products are prepared or conditioned or where animais are slaughtered or quartered must be located in s site free from strong or foul odours and from all sources of pollution and l>e provided with an adequate and perfectly maintained and functioning system for removing its waste fluids.The surroundings must be well drained and kept iu a satisfactorily clean ami sanitary condition and must not constitute a health hasard.Art.13.\u2014Every plant must l>e big enough to permit efficient operating and must have suitable ami adequate premises and facilities for its purposes.It must be well lit and Ventilated and have an ample supply of potable water of irreproachable chemical ami bacteriological quality.It must have complete protection against insects, rodents ami other animals ami against all sources of |xdlution or contamination.Art.11.\u2014The floors ami walls must be made of, or faced with, resistant, impervious, ami smoothly surfaced materials.The floors, ceilings, walls, ami all equipment or installations must be easy to clean and kept in a perfect state of maintenance, cleanliness ami hygiene.Art.15.\u2014The material organization «»f the plant, the sanitary equipment and maintenance of its premises and buildings, machinery, implements and fittings, ami the operating met hods and procedures must lie in keeping with recognised professional and hygienic standards ami with all instructions which the Minister may see fit to issue in the interests of public health «>r l«> ensure respect for the Act ami Regulations.Art.10.\u2014The regulations concerning plants also apply to places where food is bought and sold or consumed, ami to places containing or intended to contain food.Places from which animals or other products intended for food production are derived or where they are kept must l>c maintained in faultlessly clean and hygienic condition. 2610 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 avril 1007, 99' année, n° 15 Section 11.\u2014-Opérations.Art.17.\u2014Toutes les opérations doivent être effectuées selon des méthodes éprouvées et reconnues en industrie ulimentuire et dans «les conditions propres n éliminer toute possibilité de pollution, de contamination ou d'altération du produit.Art.18.\u2014L'exploitant «loit user «le moyens u«lé«piats pour contrôler lu provenance, la qualité, l'intégrité et lu température «lu produit, la température et le degré d'humidité «lans les locaux, le fonctionnement «les appareils et la bonne marche «les opérât ions.Ce contrôle «loit s'exercer à la satisfaction «lu ministre et «le façon à en faciliter la vérification par un inspecteur.Art.19.\u2014Le personnel «loit être suffisamment instruit pour bien remplir sa tâche et ne «loit présenter aucun danger «le contamination.Il «loit être astreint à la plus grande propreté vestimentaire et corporelle et à une stricte observation «les règles du métier et «le l'hygiène.Il «loit avoir à sa disposition tout ce qui est nécessaire à cette fin.Art.20.\u2014Tout pro«luit altéré ou impropre à la consommation ou qui ne répond pas aux exigences «le la loi et «les règlements «loit être aussitôt éliminé.Il en est «le même «le tout matériel, objet ou matériau défectueux, malpropre ou insalubre, ou qui ne convient pas aux opérations, ou dont l'emploi est inter«lit.Art.21.\u2014Les exploitants d'abattoir ou «l'atelier «l'équarrissage, les fabricants, préparateurs, conserveurs, conditionneurs ou entrepositaircs d'aliments doivent tenir «les registres de leurs opérations et tenir à la disposition des inspecteurs l'intégralité «le ces registres et «le leurs écritures commerciales.Les registres doivent imliquer chaque entrée «le produits, leur provenance et leur utilisation, ainsi que chaque sortie «le produits et leur destination.Ces registres sont conservés pendant un un au moins à dater du jour de la dernière inscription qui y est portée.Le ministre peut exiger tout rapport ou renseignement qu'il juge utile sur les opérations visées au présent article.Sect ion III.- J éh icuks.Art.22.\u2014Tout véhicule affecté au transport «lu produit doit convenir parfaitement à cet usage, être apte à assurer le transport «lans de lionnes conditions et être maintenu en parfait état d'entretien, «le propreté et «le salubrité.II ne doit pas servir d'une façon impropre à cet usage, ni séjourner en milieu insalubre, malpropre ou malodorant, ni être exposé à la souillure ou ù la contamination.Art.23.\u2014Il «loit être équipé, aménagé et utilisé de façon à tenir bien à couvert le produit et le récipient ou l'emballage qui le contient, à les maintenir à la température qui convient et à les protéger parfaitement contre toute cause de pollution, de contamination ou de dépréciation.Art.24.\u2014Le chargement, le transport, le «léchargement ou la livraison doit s'effectuer avec soin et diligence, duns «les conditions de propreté et «l'hygiène irréprocliables et «le façon à sauvegarder la qualité et la salubrité du produit, du récipient ou de l'emballage.Art.25.\u2014Est prohibé le transport d'un pro-tluit qui n'est pas conditionné, emballé et marqué conformément aux normes prescrites, ou dont Division 11.\u2014Operations.Art.17.\u2014All operations must be carried OUI in accordance with proven ami recognized methods of the f«H)tl industry ami umler conditions f his equipment and tin smooth conduct of his operations.This control must be exercised to the satisfaction of the Minister and in such a way u to permit checking by an inspector.Art.19.\u2014The personnel must ba sufficiently instructed to do their work properly ami nuut not involve any risk of contaminât ion.A high standard of cleanliness, both Si to person and clothing, ami strict observance of professional and hygienic standards must !«\u2022 required of them and everything needed for these purposes must be at their disposal.Art.20.\u2014All products which arc spoilt or unfit for consumption or do not meet the requirements of the Act and Regulations must be eliminated immediately.The same applies to any equipment, object or material that is defective, dirty, or insanitary, unsuited to the openv tions or forbidden to lie used.Art.21.\u2014Operators ot slaughterhouses or plants for «lismemlicring «lea«l animals, ami persons engaged in the production, proccssnuj, preservation, conditioning ami warehousing of food must keep records of their operations ami hold the intact records and all their etinnncrcial documents at the disposal of inspectors.The records must show every arrival d products, their source and utilization, and every shipment of products and their destination.These records must lie preserved for at least a year after the «late of the last entry made in them.The Minister may demand any report 01 information he may deem useful concerning the operations rcfcrrctl to in this article.Division III.- Vehicles.Art.22.\u2014Every vehicle serving for the transport of a product must be perfectly suitable far the purpose ami for ensuring transport umler g«iod conditions, and he kept in a perfect slate of maintenance, cleanliness, and hygiene.It must not lie used in any manner incompatible with or detrimental to this purpose, \"r stand in a dirty, insanitary, or foul-smelling place, nor be exposed to defilement or contamination.Art.23.\u2014It must lie equipped, organised ami usetl in such a way as to keep the product and its container or package well under cover, at tl«' proper temperature, and completely protected against all sources of pollution, contamination or «Ictcrioration.Art.24.\u2014Loading, unloading, conveyance and delivery must be carried out carefully and promptly, under faultless conditions of cleanliness ami hygiene, ami in such a way as to safeguard the quality and wholcsomencss of the produel ami its container or package.Art.25.\u2014It is forbidden to transport a product which is not conditioned, packed and labelled in accordance with the specified shtml- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1907, To.99, So.15 2511 |, récipient ou l'emballage est défectueux ou mal iVriné.Art.26.\" Kst prohibé le dépôt ou le transva-auuenl du produit sur la voie publique ou ù proximité de cette voie ou dans un endroit exposé au soleil OU aux conditions atmosphériques, ou qui n'est pas à l'abri de toute eause de ixdlution, de i .\u2022illumination ou de dépréciation pour le produit, le récipient ou l'emballage.Art.27.Tout véhicule affecté à la vente et à la livraison à domicile, à un magasin de détail mi à un lieu de consommation, doit être clos, ne servir qu'à cet usage et n'être ouvert qu'au moment de la livraison.Il doit porter, en caractères indélébiles et très apparente d'au moins trois pouces de hauteur, s'il ses faces latérales, des inscriptions indiquant la nilure du produit et l'identité du vendeur «I du fabricant OU préparateur.TiittB III.- -Conditionnement et vente.Section I.\u2014Dénomination et composition.Art.'Jv La dénomination appliquée au produit doit indiquer la nature exacte de ce produit el être applicable à tout produit présentant des caractères analogues.Elle «loit être précise et ne prêter à aucune étpiivoquc.Dans le cas d'un produit artificiel, synthétique, de fantaisie ou «l'imitation, la dénomination doit être propre à distinguer nettement celui-ci d'un produit dont il existe un type défini, naturel «m li\\é par l'usage.Art.29.- Aucune appellation «l'origine ne doit être appliquée à un produit contrairement à l'origine de celui-ci ou à des usages locaux, loyaux et constants.Art.30.\u2014iLea qualificatifs suivants et toute mention é«piivalentc sont exclusivement réservé-: 1° pasteurisé»: à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est débarrassé «le microbes pathogènes et est maintenu en cet état jusqu'à sa livraison au consommateur; 2 stérilisé » : à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est «lébarrassé «le tout microbe vivant et est maintenu en cet état jusqu'à sa livraison au consommateur; \u2022*5° homogénéisé»: à un produit qui, par un procédé loyal et approprié, est uniformisé et Stabilisé «lans toutes ses parties et maintenu en ret étal jusqu'à sa livraison au consommateur; 4° congelé»: à un produit qui a subi, «lans toutes ses parties, un abaissement de température «n dessous de son point «le congélation et est maintenu en cet état jusqu'à sa livraison au consommateur; \u2022' surgelé » ou « congelé ultra rapidement »: a un produit répondant à toutes les conditions qu impose l'application «le la technique dite « de congélation ultra rapide» aux divers stades, depuis la récolte ou préparation jusqu'à la livraison au consommateur.Art.31.\u2014La composition et les particularités nu produit doivent être conformes à celles alors prt \\ ues |)our ce produit sous le régime «l'une loi oui Québec ou, en l'absence «le telle prévision, à «\u2022elles alors prévues pour ce produit sous le régime de la Loi «les aliments et drogues ou «le la Loi relative aux aliments du bétail.Il en est de même jje lu dénomination et de toute mention qui i accompagne.ards or whose container or packaging is defective or not properly closed.Art.2(>.\u2014It is forbidden to deposit the product or transfer it from one container to another on or near a public thoroughfare or in a place which is exposed to the sun or weather or unprotected from all sources of contamination, pollution or deterioration of the product, container or packaging.Art.27.\u2014Every vehicle serving f«»r the selling ami delivering of foo«l products to homes, retail stores or places of consumption must be enclosed ami Used only for such purpose, and be opened only at the time of delivery.It must display on its sides, in indelible and conspicuous letters at least three inches high, the nature of the product ami the name of the vendor, maker, or processor.I'aht III.\u2014Conditioning and S ale.Division I.\u2014Same and Composition.Art.28.\u2014The name used to designate a product must indicate the true nature of the product, be applicable to all products having similar characteristics, and l>e exact and free from ambiguity.The name usc«l t«> designate an artificial, synthetic, imitation or fancy product must Im* such as to distinguish that product from existing products of a well-defined natural, traditional, or timc-honoure«l type.Art.29.\u2014No local trade name or indication of origin shall be applied to a product if the said name or indication is inconsistent with the origin of that product or with honest ami established local practice.Art.30.\u2014The following terms or any expressions equivalent to them shall lie restricted as hereinafter specified: 1.\"pasteurised\", to a product which, by means of a suitable, recognised process, has Ikmmi ri«l of pathogenic microorganisms ami is kept in that condition until its delivery to the consumer; 2.\"sterilised\", to a product which, by means of a suitable, rceognizetl process, has been ri«l of all living microorganisms and is kept in that condition until its delivery to the consumer; 3.\"homogenized\", to a product which, by means of a suitable, recognized process, has been rendered uniform throughout and stabilized and kept in that condition until its delivery to the consumer; 4.\"frozen\", to a product all parts of which have been reduced to a temperature below its freezing point and kept in that condition until its delivery to the consumer; 5.\"«leep-frozcn\" or \"ultra-rapid frozen\", to a product satisfying all the conditions rcquirc«l by the \"ultra-rapid freezing\" technique at the various stages from harvesting or preparation until delivery to the consumer.Art.31.\u2014The composition and characteristics of a product and its name and all information accompanying it must conform to the then relevant provisions in force under an Act of Quebec or failing such, under the Food ami Drug Act or the Fee«ls Act. 2512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, M avril 1907, 99' année, n° 15 Art.32.-Ne doit être présente duns ou sur un produit, ni entrer duns su composition ou servir à su prépuratiou, aucune suhstuucc dont lu présence, l'uddition ou l'utilisution est ulors prohibée sous le régime d'une loi du Quéliee ou, «'il l'uhsence «le telle prohibition, est ulors prohilu'e sous le régime «le lu Loi «les aliments et «Irogues ou «le lu Loi relative aux aliments «lu bétail.Huns le eus d'une uddition ou utilisation autorises ou «l'une tolérance prévue sous le rfgimc «l'une «le ces lois et n«ui prohibée en vertu de l'alinéa précédent, toutes les conditions de l'autorisation ou «le la tolérance doivent être observ«Vs.Art.88.'\u2014Est intcnlite toute «lérogution uux usages loyaux et c«mstants «lu commerce relativement à la «lénomination ou à une mention applicable au produit, ou relativement si la compo-sititm, à la préparation, à l'état, à l'intégrité ou à une particularité du produit.Seetion II.- -Récipients et emballages.Art.84.\u2014Tout récipient, emballage, appareil, dispositif, ustensile ou objet utilisé pour recueillir, mesurer, conserver, transjxirter, livrer ou servir le produit l' fait par l'inscription du nom du pays d'origine s'il s'agit d'un produit canadien, du mot * < anada » ou du nom de la province d'origine, d une expression équivalente.Art.14.\u2014Est interdite toute indication ou marque relative à un contrôle sanitaire ou autre, » Un certificat officiel, une garantie, une loi ou Un règlement, à moins qu'elle ne soit autorisée may be, must lie exact, truthful and sincere, and must not be susceptible to any possible confusion or misunderstanding.The use of French is obligatory in all inscriptions, and inscriptions in another language must not take precedence over those in French.This regulation does not apply to a document accompanying the side and drawn up in the language of the buyer.Art.39.- -The product must be accompanied by the information or markings necessary to ensure honest sale.Art.40.\u2014Every product processed or conditioned with a view to sale must display on its container, package or wrapping, in indelible, plainly legible and conspicuous characters: 1.the markings necessary to show (a) the nature, condition, composition, use, exact quantity, origin, and all other particulars of the product; (b) the identity of its manufacturer, preparer, conditioner or processor; (e) its place of manufacture, preparation, conditioning, or processing, 2.all inscriptions prescribed by Acts or Regulations then in force or required to comply with the honest and established practices of the trade or to ensure honest sale.Listing of the constituents of a product must be according to decreasing order of their proportions in the product.The indication of weight must take into account the loss to which the product may normally be subject after its conditioning, and must be expressed as net weight.Art.41.\u2014 During display in the retail trade, the price a piece or |>cr unit of weight or measure must appear conspicuously on the product or on its package or container, or on a placard referring to a uniform lot of identical products.The price marking must be accompanied by: (a) the name of the product if there can be any uncertainty about its precise nature; (b) indication of the origin of the product, in the case of a natural product which has a similarity to a product of Quebec hut does not come from Quebec; (c) all markings or information prescribed by an Act or Regulation then in force or required to comply with the honest and established practices of the trade or to ensure honest sale.Art.42.\u2014In places of consumption, the menu or, failing that, a placard displayed to the public view must show, in plainly legible and conspicuous characters, the nature of the products and the price of meals, snacks, portions, or beverages.Art.43.\u2014The indication of origin of a Quebec product or of one manufactured in Quebec must contain the word \"Quebec\", which shall lie restricted to such products.The indication of origin of all other products shall be by the name of the country of origin or, in the case of a Canadian product, by the word \"Canada\" or the name of the province of origin or an equivalent expression.Ait.44.\u2014All markings or notations with reference to a sanitary or any other control, or to an official certificate, guarantee, Act or Regulation, unless specifically authorized or prescribed by an 8514 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, lô avril 1907, 99' année, n° 16 OU prescrite par une loi ou un règlement et ne soit utilisée de la manière et dans les conditions prévus par cette loi ou ce règlement.Ksi également interdite, sauf dans le commerce pharmaceutique, toute indication tie propriétés curatives ou préventives au sujet du produit, à moins qu'ellfl ne soit autorisée ou prescrite par une loi OU un règlement et ne soit utilisée de la manière cl dans les conditions prévues par cette loi ou ce règlement.Art.45.\u2014Commet une infraction quiconque frauduleusement: 1° opère quelque changement dans le contenu de l'emballage, du récipient ou de l'enveloppe; 2° emploie une étiquette qui a déjà servi; 3° supprime, manque, altère ou modifie de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de séries, emblèmes, mentions, .signes de toute nature apposés sur le produit et servant à l'identifier; 4° fait une déclaration OU emploie un moyen susceptible de tromper un acheteur «le quelque façon.Titre IV.\u2014Contrôle h repression.Section I.-Mesures générales.Art.40.\u2014Le ministre exerce, par le service de la salubrité et tout inspecteur qu'il autorise: 1° Un contrôle sanitaire sur les animaux et les produits destinés à la production d'aliments, les lieux de provenance ou de détention et les moyens de transport de ces animaux ou produits; 2° Une surveillance spéciale sur les opérations relatives à l'abattage et à l'équarrissage des animaux, à la préparation, transformation et conservation et au conditionnement des viandes «ai autres aliments; 3° Une surveillance générale sur tout ce qui donne lieu à l'application de la loi et du présent règlement.Art.47.\u2014Le propriétaire ou l'exploitant doit faciliter l'exercice de ce contrôle et de cette surveillance et se conformer aux ordres OU directives que le service «le la salubrité ou un utspec* tcur lui donne, «lans l'intérêt «le la santé publique ou pour assurer le respect de la loi de «les règlements.Art.48.\u2014Nul ne peut vendre ou livrer, en dehors «le la ferme d'origine ou du voisinage de cette ferme, «lu lait ou «le la crème à l'état cru au consommateur pour la consommation humaine, à moins que ce produit ne provienne d'une ferme reconnue salubre par le ministre.Art.49.\u2014Le service de la salubrité délivre à cette fin un certificat de salubrité à l'exploitant de la ferme, qui en fait la demande et qui, dans l'opinion du ministre, offre des garanties suffisantes p«)ur assurer le respect de la loi de des règlements.Le titulaire «loit exposer ce certificat dans son établissement à la vue de ceux qui font affaires avec lui.Art.50.\u2014Le certificat n'est valable que pour son titulaire et la fin y spécifiée.Il devient caduc de plein droit dans le cas «le refus du titidaire d'autoriser ou de faciliter le contrôle jugé nécessaire par le ministre ou dans le cas de l'inobservation d'une disposition de la loi ou de* règlements.Act or Regulation and used in the manner ami conditions prescribed therein, is forbidden Except in the pharmaceutical trade, an | itate.ment about curative or preventive prop rtiesel a product unless authorized or prescribe I l,v an Act or Regulation ami used in the manner aid conditions prescribeil therein, is likewise for.bidden.Art.45.Is guilty of an infringement who*), ever fraudulently: 1.makes any change in the contents crson concerned or left at his residence in the hands of a reasonable member of his household, or with an employee at his establishment.In the second case, the notification shall be published in the Quebec Official Gazette.Art.53.\u2014The prohibition shall come into force from the time of receipt of notification thereof by the person concerned, a reasonable member of his household or an employee of his establishment, or on the «late of publication of the notification of prohibition or on a later «late specifieil in the notification.Art.54.\u2014No person shall violate a prohibition which is in force.The Minister may remove the prohibition by means of a notification communicated or published in the manner stipulated for the notification of prohibition; whereupon the prohibition shall cease to l>e in force.Division 11.-Supervised Plants.Art.55.\u2014At the request of the operator, the Minister may place under the permanent supervision of a veterinary surgeon inspector on conditions that he may fix, the operations of a plant where animals are slaughtered or where the meat or other parts of animals are prcparetl or n«li-tioned for human consumption.The Health Service shall keep a register in which supervised plants shall be entered.Art.50.\u2014The Minister may authorize the use.umler the control of the inspector ami on the conditions hereinafter specified, of a circular stamp having a fleur-«lc-lis ami the registration number of the plant in the middle, with the word \"Quebec\" above and the won! \"Approved\" below, ami he may prescril)c the type, dimensions, an«l manner of use of the stamp.Art.57.\u2014The stamp may appear only on meat or parts of an animal, whether in the natural state or processed, which were found to be wholesome, fit for human consumption and in perfect condition by the inspector at the time when the protluct was stamped and when it left the plant, and which came from an animal fourni by an inspector to be healthy, fit for human consumption ami in perfect condition upon examination before, during, ami after slaughter.Art.58.\u2014The inspector, either personally or through his subordinate, shall watch over: 1.admissions of animals or raw materials, and the identification, state of health and quality of the animals and the origin, nature and quality of the raw materials; 2.the slaughtering, processing, or other operations, the quality of the slaughtered meat 2610 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 avril 1967, 00' année, n° la préparés, hi sortit' et lu destination de ces viandes ou produite; 3° les condition! de transport ou «le détention «le OBI animaux, matières, viandes ou produits, «\u2022t les conditions «l'emballage et de marquage «le COS matières, viandes ou produits; 4° l'élimination des animaux, matières ou produits insalubres, de mauvaise «pialité ou impropres à l'alimentation humaine et la mise à l'écart des animaux, matières ou produits suspects «l'insalubrité ou «le mauvaise «pialité; f>° l'utilisation «le l'estampille, «le tout certi-li«-at «m autre document, «le tout sceau OU cachet, «le tout instrument «m matériel «le marquage; 0° l'observation rigoureuse «les lois et règlements, «les règles «le riiygiène, «les loyaux usages «le la profession, «les comblions fixées en vertu «le l'article \u2022\"»\u2022\"».Il surveille tout, rien ne «loit lui échapper ni être soustrait à son contrôle» L'estampille, y compris tout ce qui porte l'estampille «lans l'atelier, doit demeurer constamment sous sa garde.Rien ne peut entrer «lans l'atelier ni en sortir sans sa permission ou contrairement à ses instructions.Art.ôl).\u2014L'exploitant «loit faciliter la tâche «le l'inspecteur, lui réserver un local servant «le bureau, mettre à sa «lisposition le personnel et le matériel requis, assurer l'exécution «le ses ordres, instructions «ni décisions, ne rien soustraire à sa surveillance.Art.60k'\u2014La surveillance a uniquement pour but «l'assurer une meilleure protection pour le public.Elle n'a pas pour effet «l'atténuer le moindrement la responsabilité «le l'exploitant ou «lu personnel de l'atelier.Art 61.\u2014Aucune viande ou partie «l'un animal, à l'état naturel ou fabriqué, destinée à l'alimentation humaine ne peut sortir «le l'atelier, à moins «l'être munie «le l'estampille OU, «lans le cas prévu à l'alinéa suivant, accompagnée «l'un certificat d'inspection.l'eut être accompagné «l'un certificat «l'inspection, au lieu d'être muni «le l'estampille, un produit naturel expédié en vrac à un atelier surveillé, dans un colis OU véhicule plombe BOUS le contrôle «l'un inspecteur.Le bris «lu plombage ne doit s'effectuer que sous le contrôle «l'un inspecteur.L'estampille ou le certificat d'inspection n'est pas requis, cependant, «lans le cas d'un produit naturel expédié à un atelier surveillé pour y .subir, avant estampillage, un traitement approprié.L'inspecteur note, sur la feuille d'expédition prévue à l'article 63, la nature et la quantité «lu produit expédié à cette fin.Art.02.\u2014Le certificat d'inspection est délivré par l'inspecteur «le l'atelier «l'origine et constate que le produit, à sa sortie, est sain, propre à l'alimentation humaine et en parfait état.11 porte les indications requises pour révéler la nature et la quantité du produit, la date de la sortie, l'identité de l'expéditeur, «lu destinataire, «lu transporteur et du Véhicule servant au transport.Lorsqu'un véhicule contenant des produits destinés à plusieurs ateliers est plombé «le nouveau en cours «le route, l'inspecteur ou son préposé note cette opération sur le certificat d'inspection accompagnant les produits.Art.63.\u2014L'exploitant ne peut entreposer en dehors de son atelier un produit destiné à l'alimentation humaine, à moins que ce produit ne and prepared products, and the departu e sad destination of the incut or pro buds; 3.the conditions under which the aforesaid animals, materials, meat or products an trails, ported or held, ami the packaging and i Larking of the materials, meat or products; 1.the éliminât ion of animals, materials ur products which arc unwholesome, of ba I quality, or unfit for human consumption, and tile setting apart of animals, materials or products suspected of being unhealthy, unwholesome or of had quality; .\").the use of the stamp ami «>f all cert 11ii utesQf other documents, seals or marks, and all marking implements or materials; 0.the strict observance «>f Acts and lieguh.tions.«>f the hygienic standards and fair practical of the profession, and of conditions set bj virtue of article 55, He is to keep a watch over everything and nothing should escape him or be exempt from lii< control.The stamp and everything in the plant which bears the stamp must remain under his custody at all times.Nothing may enter or leave the plaid without his permission or contrary to his instructions.Art.50.\u2014'The operator must facilitate the inspector's work, make a room available to him for an oilice, place at his disposal the required Personnel and materials, ensure that his orders, directions and decisions are carried out, and not conceal anything from his supervision.Art.00.\u2014The sole purpose of this supervisionu to ensure belter protection for the public.Il does not «liminish the responsibilities of the operator or employees of the plant in the slightest.Art.01.No meat or part of an animal.whether in the natural state or processed, which is intended for human consumption may leave the plant unless it bears the stamp or, in the ease provided for in the following paragraph, unless it is accompanied by a certificate «»f inspection.A natural product shipped in bulk to ;i supervised plant in a parcel or vehicle sealed under the inspcr hiunsn consumption unless the said product la duly QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 1», 1907, Vol.99, A'o.JÔ 2517 mil dûment emballé et marqué et ne soit entrepose* dans Un entrepôt agréé par le ministre et régulièrement inspecté.In, feuille d'expédition portant les indications visée» au deuxième alinéa de l'article 02 doit accompagner tout produit destiné ù l'alimenta-tati.iu humaine, à sa sortie de l'atelier ou de l'en- t«#t., -3, .1 Art.64.Toute viande ou partie d un animal, à l'étal naturel ou fabriqué, entrant à l'atelier doit: 1 provenir d'un animal abattu dans un atelier surveillé; 2 èt re munie de l'estampille ou accompagnée ,|u certificat d'inspection ou de la note inscrite par l'inspecteur, en vertu de l'article 01, sur lu feuille d'expédition; :; venir directement d'un atelier surveillé ou, dan- le cas prévu à l'article 03, de l'entrepôt où l'exploitant a entreposé son produit; I et re accompagnée de la feuille d'expédition prévue à l'article 63; .\") avoir été transportée dans des conditions pmpres à en assurer la salubrité et la parfaite conservation; ii être reconnue saine, propre à l'alimentation humaine et en parfait état ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 01, jugée convenable par l'inspecteur, lors de l'entrée.Peut, dans les mêmes conditions, entrer à l'atelier un produit soumis, sous le régime de la Loi sur l'inspection des viandes ou sous un régime municipal d'inspection agréé par le ministre, à un contrôle sanitaire analogue à celui prévu par la présente section.Art.t>5.L'exploitant de l'atelier de préparation ou de conditionnement doit soumettre à l'approbation préalable du ministre: I ses sources d'approvisionnement; - ses procédés de préparation ou de conditionnement; \u2022'! les appareils devant servir aux opérations; 1 la nature ou la composition et les particularité.-, «lu produit préparé ou conditionné et le pourcentage en poids de chacun de ses com- posants; 5 la dénomination et le nom de fantaisie ou la marque sous lesquels doit se faire la vente du produit; 6 la matière, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes «levant servir à la vente en détail, ainsi que les inscriptions devant y figurer.Art.66.\u2014La demande d'approbation doit contenir toutes les indications nécessaires pour permettre au ministre de se prononcer et être accompagnée de trois fac-similés des récipients, emballages, enveloppes et inscriptions soumis à \"approbation.Le ministre peut exiger tout autre renscigne-toenl qu'il juge utile.Art.07.\u2014Le produit destiné à être livré au consommateur doit être préparé, conditionné et marqué dans l'atelier conformément aux indications de la demande d'approbation et aux conditions de l'approbation.Art.6S.\u2014L'autorisation prévue à l'article 50 peut être retirée ou suspendue pour une cause ÏMgée suffisante par le ministre.Avis du retrait ou de la suspension est adressé à l'intéressé.packed, marked, and kept in a storage which is approved by the Minister and inspected regularly.On their departure from the plant or storuge, all products intended for human consumption must be accompanied by a shipping bill bearing the information referred to in the second paragraph of article 02.Art.64.\u2014All meat or parts of an animal entering the plant, whether they are in the natural state or processed, must: 1.liave been derived from an animal slaughtered in a supervised plant: 2.bear the stamp or be accompanied by the certificate of inspection or by the inspector's annotations, as stipulated in artiele 01, on the shipping bill; 3.have come directly from a supervised plant or from a storage in which the operator has stored his product under the conditions specified in article 03; 4.be accompanied by the shipping bill referred to in article 63; 5.have been transported under conditions calculated to ensure their wholesomcness and perfect keeping; 6.be found to be wholesome, fit for human consumption and in perfect condition or, in the case provided for in the last paragraph of article 61, judged suitable by the inspector at the time of their admission to the plant.A product which lias been subjected to a system of sanitary control equivalent to that stipulated in this division, under the Meat Inspection Act or under a municipal system approved by the Minister, may also be admitted to the plant provided that the conditions of this article arc satisfied.Art.65.\u2014The operator of a plant where food products are to be prepared or conditioned must submit the following details of his enterprise for the Minister's prior approval: 1.his sources of supply; 2.his methods of preparation or conditioning; 3.the equipment to be used for these operations; 4.the nature or composition and the characteristics of the product to lie prepared or conditioned and the percentage by weight of each constituent; 5.the name and the brand or trade name under which the product is to be sold ; 6.the shape, dimensions, capacity, and material of the containers, packages or wrappings to be used for retailing the product ami the markings to appear thereon.Art.66.\u2014The application for approval must contain all the information required for the Minister to reach a decision and be accompanied by three facsimiles of the containers, packages, wrappings and markings it is proposed to use.The Minister may demand any other information he may consider useful.Art.67.\u2014Products intended for delivery to consumers must be prepared, conditioned, and marked in the plant in conformity with the details contained in the application for approval and with the conditions of approval.Art.68.\u2014The authorization referred to in article 56 may be withdrawn or suspended on grounds considered by the Minister to be sufficient.Notice of such withdrawal or suspension shall be given to the person concerned. 25 IS GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 16 avril 1007, 00' année, n° 1» l.c retrait entraîne lu radiation de l'atelier du legist re des ateliers surveillés, la parti ermission ou en dehors du contrôle de l'inspecteur ou contrairement aux conditions prévues pour cette utilisation; 2° Tait croire ou tente de faire croire faussement qu'un produit ou un atelier bénéficie de la surveillance jK'rmanente, de l'estampille ou du certificat d'insj>ection; 8\" Sciemment vend ou livre, ou met en vente ou en circulation sous une estampille ou un certificat d'insjH'ction, un produit ne répondant pas alors aux conditions prescrites, ou en est trouve détenteur «lans ses locaux ou véhicules commerciaux; 4° Imprime ou reproduit, fait imprimer ou repro«luire, l'estampille sur une éti«pjette ou un «)bjet quelconque, vend ou livre, met en vente ou en circulation, cette étiquette ou cet objet sans la permission ou en dehors «lu contrôle «lu service de la salubrité ou contrairement aux conditions prévues pour l'emploi de l'estampille; 5° Agissant comme inspecteur ou préposé, a un intérêt quelconque «lans un atelier d'abattage ou d'équarrissage d'animaux ou un atelier de préparation ou de conditionnement de viandes, aihats ou issues, ou «lans le commerce ou la vente de ces animaux ou produits.Section III.-Inspection et répression.Art.71.\u2014-Les infractions à la Loi des produits agricoles et des aliments ou au présent règlement sont recherchées et constatées conformément aux dispositions «le la présente section.Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve «lesdites infractions puisse être établie par toute voie de «Iroit.Art.72.-\u2014Est qualifié |>our procéder aux recherches, faire «les prélèvements et, s'il y a lieu, effectuer «les saisies ou confiscations tout inspecteur autorisé par le ministre.Art.73.\u2014Le prélèvement, la conservation et l'analyse des échantillons se font selon les méthodes prévues «lans la législation ou réglementation alors en vigueur ou, en l'absence «le prévision, selon des méthodes éprouvées et reconnues par la profession et agréées par le ministre.Le ministre désigne les laboratoires autorisés à procéder aux analyses et en détermine le ressort et les attributions.Art.74.\u2014L'inspecteur a le droit d'interroger toute personne qu'il croit en mesure «le l'éclairer dans ses recherches.Withdrawal of the said authorization >|u|| entail the deletion of the establishne < f,.\u201em the register «>f supervised plants, loss of the advantages conferred by the stamp am] hv pernunent supervision, and the confiscation of products, pacluujes, containers, wrappings, labels or objects bearing the stamp unless the \\ii,| mark is obliterated, removed or otlwrwkt «lcstroye«l without «lelay under the uuqiector'i control ami in accordance with bis orders.Suspension of the authorization, while in force, shall have the same affect as with l.awal.with the exception «>f deletion from the register and of any mitigation allowed by the Minister.Art.SO.' -The Minister may publish, from time to time ami through any medium, the list of plants entered into or deleted from the register of supervised plants, or announce air.entry into or deletion from the said register.Art.70.\u2014Is guilty of an infringement whom- ever: 1.Uses «>r attempts to use the stamp or certificate of inspection without the iu-p tor.permission or supervision or contrary to the conditions laid down f«>r such use; 2.Kramlulently makes believe or tries to make believe that a product or plant is subject to permanent supervision or entitled to tat stamp or certificate «>f inspection; 3.Knowingly sells or «lelivcrs, or puts on sailor in circulation umler a.stamp or certificate ol inspection, a product which «lues not satisfy tin-requirements in force, or is found t«> have such a product on his commercial premises or vehicles; 1.Prints or reproduces the stamp or causes il to be printed or reproduced on any label or object whatsoever, or sells, delivers or put - a label or object so stamped or marked on sale or in circulation without the permission or supervision of the Health Service or contrary to the condi-tions laid down for the use of the stamp; 5.While working as an inspector or inspector'! subordinate, has any interest whatsoever in a plant for slaughtering or quartering animals or preparing or conditioning meat or other puts of animals, or in the commerce or sale of such animals or products.Division III.- Inspection and Enforcement.Art.71.\u2014Infringements of the Agricultural Products ami Pood Act or of these Regulations shall be investigated and established in accordance with the provisions of this Division.These provisions shall not prevent proof of the said infringements by any legal means.Art.72.- -Any inspector authorised by th*' Minister shall l>c entitled to undertake investigations, take samples and, if there is «lue call*, make seizures or confiscations.Art.73.\u2014The taking, keeping, ami analysis « samples shall be carried out in accordance with the methods land down in the Acts or Regulations then in force or, failing such specific legal provision, in accordance with proven methods recognised by the profession and approved by the Minister.The Minister shall designate the laboratory authorized to carry out analyses and shall specify their scope and powers.Art.74.\u2014An inspector has the right to interrogate any person he considers able to enlighten him in his investigations. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1967, Vol.99, No.15 2519 I.,, personne interrogée «loit répondre tonné* 1,1,1,1,1 cl au meilleur «le sa connaissance et intelligence à rinterrogatoire susdit et représenter à l'inspecteur, ù sa réquisition, les documents et livres dont elle est.détentrice et qui concernent mu- opération soumise à l'application de la loi ,\u20221 .lu règlement.Les réponses et les éléments d'information reçut illis, .-.'il est jugé utile, sont rapportés «lans un procès-verbal rédigé à cette lin et qui comporte les inentions prévues à l'article 80.Art.75.L'inspecteur témoin «l'une infraction en «liesse immédiatement procès-verbal uii !! consigne, avec les mentions prévues à l'article 80, les circonstances propres à établir l'infracl ion.Art, 76.Le prélèvement d'échantillons peut, en toute circonstance, être o|>êré «l'office.Il esl obligatoire «lans le cas «)ù un produit para!! falsifié OU impropre à la consommation.Le produit est alors placé sous saisie, en attendant le résultat «le l'analyse «le l'échantillon prélevé.La confiscation est obligatoire «lans le cas où un produit est reconnu falsifié, impropre à la consommation ou susceptible «le servir à une fraude ou falsification.Ail.77.Le produit saisi est laissé en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, transporté en lieu sur.Le produit confisqué est placé sous scellés.L'inspecteur peut le laisser en dépôt à l'intéressé ou le faire transporter en lieu sûr.S'il s'agit d'un produit visé au troisième alinéa de l'article 70, l'inspecteur peut procéder à sa destruction, stérilisai in ou dénaturation.L'inspecteur appose un bulletin numéroté et daté sur tout lot «l'un produit saisi ou confisqué el laissé en dépôt.Ce bulletin doit porter la mention «saisi» ou «confisqué'-, suivant le ea-.en vertu «le la Loi «les produits agricoles et des aliments» et la signature «le l'inspecteur.Les opérations relatives à la saisie ou confiscation >i >nt relatées au procès-verbal.Art.78.- Nul ne peut vendre ou offrir en v- ni.un produit saisi ou confisqué, ni enlever ou permettre «l'enlever ce pro«luit, son contenant u La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué; \u2022> Les nom, profession et «lomicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré; si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domicile des personnes figurant The person interrogated must answer the inspector's questions honestly and to the best of his knowletlgc ami understanding and, at the inspector's request, must produce for his scrutiny any documents and books in his keeping which concern an opcrat ion subject to the provisions of the A«-t ami Regulations.The replies or essential details of the information SO obtained, if considered relevant, shall be set down in a procès-verbal drawn up for the purpose and reporting the details specified in article 80.Art.75.-Any inspector who witnesses an infringement must immediately draw up a procès-verbal in which, in addition to the details stipulated in article 80, he shall record circumstances apt to establish proof of the infringement.Art.70.\u2014The taking of samples may b«-carried out, in any circumstances, as a matter of routine.Sampling is compulsory whenever a product appears to be adulterated or unfit for consumption.In such cases, the product shall be seized pending the result of analysis of the sampling.Confiscation is compulsory in the case of a product recognised to be adulterated, unfit for consumption, or liable to be the subject «>f fraud or falsification.Art.77.\u2014 The seized product shall be left on deposit with the interested party or, upon his refusal, removed to safe keeping.The confiscatetl pro«luct shall be placed Under seal.The inspector may leave it on deposit with the interested party or have it removed to safe keeping.In the case of a product referred to in the third paragraph of article 70, the inspector may proceed with its destruction, sterilization or denaturing.The inspector shall place a numbered and dated tag on each lot of the product that is seized or confiscated ami left on deposit.The tag shall bear the words \"Seizetl\" or \"Confiscated\", as the case may be, and \"umler the Agricultural Products and Food Act\" and the inspector's signature.Operations relative to the seizure or confiscation shall he enteretl in the procès-verbal.Art.78.\u2014No person shall sell or oll'er for sale a seize«l or confiscated product nor remove or permit the removal of such product or its container or of the seizure or confiscation tag without the authorization of an inspector or of the Minister.Art.79.\u2014Release from seizure may be given in writing by any inspector who is satisfied that the interested party has complied with the law since the seizure.Such release shall bear the date, the inspector's signature ami the following information: the date and number of the seizure, the name of the product, and the name of the person concerne»!.Art.80.\u2014Whenever a sample is taken, a procès-verbal shall be drawn up on the spot.The procès-verbal shall contain the following information: 1.the name, function, ami residence of the inspector; 2.the place, date and time of the sampling; 3.the name, occupation, ami domicile or residence of the person on whose premises the sample was taken or, if the sampling took place in transit, the name and domicile of the persons 2320 UAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, J» avril 1907, 99e année, »\u2022 lô sur lu lettre (le voilure ou le connaissement comme expéditeur ou destinataire; 4° Lu signature de l'Iaepeoteur.Ix* prncès-verhul doit, en outre, contenir un «\u2022x|K>sé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèveuUHll a été effectué, relater les marques et inscriptions (igurunt sur les récipients, emballages ou enveloppes, rini|>ortaucc du lot de mar-eliandise échuntillonm-c.ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marcluindise, la dénomination exacte sôus laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.Le propriétaire ou le détenteur de lu marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport, peut, en outre, faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile.11 est invité à signer le procès-verbal.Kn cas de refus, mention en est faite par l'inspecteur.Art.Ni.\u2014Tout procès-verlml est rédigé en triple expédition.Ix?premier exemplaire est envoyé par l'inspecteur dans les vingt-quatre heures au ministère de l'agriculture et de lu colonisation.Un exemplaire est laisse au propriétaire ou détenteur du produit ou.le cas échéant, au représentant de l'entreprise «le transport.Un exemplaire est conservé par l'inspecteur.Art.S2.\u2014Tout échantillon prélevé est mis sous scellés et adressé, en même temps que le procès-verl»al.au ministère de l'agriculture et de la colonisation.Si la nature du produit exige «les mesures ipéottùes «le conservation, l'échantillon est immédiatement envoyé au laboratoire où des mesures appropriées sont prises.Mention de «'«'t envoi est faite au procès-verbal.Les scellés sont appliqués sur une étiquette numérotée et qui porte la dénomination sous laquelle le produit est mis en vente, la date «lu prélèvement, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marcluindise ou, en cas «le prélèvement en cours «le route, ceux de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la signature «le l'auteur «lu procès-verbal.Un récépissé, détaché «l'un livre à souche, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise qui en fait la demande.En cas de prélèvement en cours de route, le représentant «le l'entreprise de transport re«^oit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des échantillons prélevés.Art.83.\u2014Dans les vingt-quatre heures de sa réception, l'échantillon est transmis au laboratoire.Le lalniratoire doit, dans les huit jours de la réception de l'échantillon ou dans le délai additionnel requis pour parfaire l'analyse, adresser au ministère un rapport où sont relatées et justifiées les opérations et constatations faites et consignés les résultats «le l'analyse.Si le rapport, ne conclut pas à une présomption de fraude, de falsification ou d'infraction, le ministère en avise l'intéressé.19243-o Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 033 Québec, le 15 mars 1907.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.mentioned in the way-bill or bill «»f lading a» shipper or consignee; 4.the inspector's signature.The procès-verbal shall also contain a liri,| statement of the cir«-uinstances under which the sampling was carried out, giving the tnule-nuuiu and inscriptions appearing on the container!, packages or wrappers, the size of the lot \u201ef incrcluindi.se sampled, and any infonuatica which might serve to establish the authenticity of the samples taken, the identity of I he eoedi, and the exact description umler which they wen offered or hehl for sale.The owner or holder «>f the merchant I i-c or Unrepresentative of the carrier, as the ease may be, may have any statements he deems Userai entered in the procès-verbal.He shall be invitd t«> sign the procès-verbal ; if he refuses t.> do mi, the inspector shall recor«l the fact.Art.81.\u2014Every procès-verbal shall i» audi out in triplicate.The inspector shall semi the original Lhereel to the Department of Agriculture and Colonisation within twenty-four hours.One copy shall lie left with the owner or holder of the product or with the representative of the carrier, sa the case may l>c.One Copy shall be kept by tin-inspector.Art.82.\u2014Every sample taken shall be phuxd umler seal ami sent to the Department of Agriculture ami Colonization at the same time aa the procès-verbal.If the nature of the product h such as to Require special methoils «>f preservation, the sample shall be sent direct ly to tin-laboratory, where the appropriate steps ahsH be taken to handle it.In such cases, mention «i( the despatch to the laboratory shall be made in the procès-verbal.The seals shall lie affixed on a numbered tag In-aring the name under which the pro.lint i-placed for sale, the date of sampling, the name and address of the owner or holder of the merchandise or, in the case of a sampling inadc i\" transit, those of the shipper ami the consignee, and the signature of the person drawing up the procès-verbal.On his request, a receipt detached from a l»ook with counterfoils shall be given to the owner or holder of the goods.If the sample is taken in transit, the carrier* representative shall be given, as a release, a receipt showing the nature ami quantity ol the sample taken.Art.83.\u2014Within twenty-four hours ol it' reception, the sample sludl l>e sent t«> the laboratory.Within eight «lays of receiving the sample,** immediately following the additumal period required to complete the analysis, the laboratory shall submit a report to the Departmenl ne* cribing the analyst's operations and his reason! for them, his findings and the result » of the analysis.If the report docs not afford grounds f»r presuming that there has been fraud, adulteration, or infringement, the Department disll so notify the person concerned.10243-o Order in Council Executive Council Chamber Number 033 Québec, March 15.1907-Present: The Lieutenant-Governor in « ounril QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15.1907, Vol.99, No.1» 2521 (mm i un ant 1'obligatiun pour les personnes visées pur l'article 16 «le la Loi «le l'impôt sur la vents en «létail «le tenir une comptabilité c) d.conserver certains documents (S.R.Q., 1904, chapitre 71 et amemlcments).A hindi «il 'il importe «le faire un règlement concernant lu comptabilité que doit tenir et les documents «pie «loit conserver toute personne visée par l'article 10 de lu Loi de l'impôt sur la venle en détail (S.R.Q., 1004, chapitre 71 et amendements) ; ATTENDU Qua l'article 81 «le ladite loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil «le faire «les règleDOents pour mettre à exécution les dispositions de cette loi selon leur sens véritable.Ii.est «m don né en conséquence, sur la proposition du Ministre «lu revenu: (Ji i: suit décrété le règlement ci-joint intitulé: Règlement concernant l'obligation pour les personnes visées par l'article 10 de la Loi de l'impôt sur la vente en détail de tenir une comptabilité et «le conserver certains documents (S.R.Q., lt)(i4.chapitre 71 et amemlcments) ».( 'opie conforme.Le Greffier du Conseil Exécutif, Jacques Piiemoxt.Règlement concernant l'obligation pour les personnes visées par l'article 10 «le la Loi de l'impôt sur la vente en détail «le tenir une comptabilité «-t «le conserver certains documents (S.R.Q., 1904, ch.71).I.Toute personne visée par l'article 10 «le la Loi «le l'impôt sur la vente en détail doit: \"i tenir, à sa principale place d'affaires dans la province «le Québec, un système «le comptabilité «-t avoir en sa possession des états financiers «\u2022t des documents complets permettant aux officiers du ministère du Revenu de vérifier en «létail: i) lei montants de la taxe qu'elle doit percevoir et remettre, ainsi que l'exactitude des remises; ii les achats pour fins de revente; iiii les achats pour fins d'usage ou «le consommation: iv) les ventes assujetties ou non à la taxe «le Vente; v) les ventes pour fins «le revente, avec le nom, I adresse et le numéro d'enregistrement de chaque acheteurs vii les ventes pour fins d'usage ou «le consommation à une détenteur «le certificat d'enregistre-meui dont le numéro est suivi de la lettre « P > SVec son nom, son adresse et son numéro d'enregistrement; vu) les ventes de marchandises expédiées hors de la province, avec le nom et l'adresse de l'acheteur, ainsi que l'endroit où l'expédition est faite.Cette personne doit de plus avoir en sa possession les connaissements et autres preuves 'le livraison.s) conserver les livres, documents et pièces mentionnés au paragraphe a) et ne les détruire qu après en avoir obtenu l'autorisation écrite du \u2022^us-ministre du Revenu.-\u2022 l«c présent règlement entrera en vigueur le jour tie sa publication dans la Gazette officielle de Québec.19229-0 CoxcKiixiNti the obligation for persons subject to the provisions of section 10 of the Retail Sales Tax Act to keep books and to preserve certain documents (R.S.Q., 1904, eh.71 and amendments).Wiiekeas is is necessary to make a regulation concerning the books to lie kept and the documents to l>c preserved by any person subject to the provisions of section 10 of the Retail Sales Tax Act (R.S.Q.1904.ch.71 ami amend, ments).Wiieheas umler section 31 of the said Act.the Lieutenant-tiovernor in Council may make regulations to carry out the provisions of this Act according to their true meaning.Wiiehefohk it is ordered, upon the recommendation of the Minister of Revenue: That the following regulation lie adopted, under the heating: \"Regulation concerning the obligation for persons subject to the provisions of section 10 of the Retail Sales Tax Act to keep books an«l preserve certain documents (R.S.Q., 1904, eh.71 ami amendments)\".True copy.Jacques Puémoxt, Clerk of the Executive Council.Regulation concerning the obligation f«ir persons subject to the provisions of section lb of the Retail Sales Tax Act t«i keep liooks and to preserve certain documents (R.S.Q., 1904.ch.71 and amendments).1.Any person subject t«i the provisions of section 10 of the Retail Sales Tax Act shall: (a) maintain an accounting system at his principal place of business in the Province of Quebec, ami have in his possession financial statements and complete documents permitting the officers of the Department of Revenue t«i verify in detail : (i) the amount of taxes to lie collected and remitted, and the exactness of the remittances: (ii) purchases made for resale; (iii) purchases for use or consumption; (iv) sales subject or not to the sales tax; (v) sales made for resale, together with the name, address ami registration number of each purchaser; (vi) sales made for use or consumption to the holder of a registration certificate whose number is followed by the letter \"P\", together with his name, address ami registration number; (vii) sales of goods shipped outside the Province, with the name and a«l«lrcss of the purchaser, as well as the place where the shipment is made.This person must also have in his possession the bills of lading and other proofs of delivery.(b) preserve the books, documents and papers mentioned in paragraph (a) and only destroy them after having obtainctl the written permission of the Deputy Minister of Revenue.2.The present regulation shall come into effect on the day of its publication in the Québec Official Gazette.19229-. 2,522 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 avril 1967, 99' année, n\" U Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 634 Québec, le 1\"> mars 19(17.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant certaines concessions fiscales au Pavillon Chrétien Inc.«le l'Exposition Universelle de 1067.attendu que l'article ô7 de la Loi du ministère ¦ lu revenu (S.R.Q., 1064, chapitre 66) permet au lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'il le juge avantageux pour le bien publie et lorsqu'il en résulterait pour le public «le graves inconvénients, «h- faire remise «le toute taxe.«Iroit ou p«:agr toll payable to the Crown, ami, furthermore, allows Bttcii remis, mission to the made by general régulation: Wherbas it is necessary to adopt, under the provisions of such section, a general regulation providing for the remission, on certain conditions, of the tax payable umler the provision-: of tin-Retail Sales Tax Act ami the Télécommunications Tax Act by the Christian Pavilion Inc.taking part in the 1907 Universal Exluliition.Wherefore, it is ordered, upon the recommendation of the Minister of Revenue: That the following regulation be a looted umler the heading: \"Regulation concerning certain fiscal concessions grantol to the ( !.i-tian Pavilion Inc.taking part in the 1907 I niversal Exhibition.\" True copy.Jacques Pki::m< f meals outside restaurants ami dining halls.Wiierkas pursuant to paragraph {e) of section 12 of the Hotels Act.Revise 1 Statutes.1064, chapter 205, the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, define the publicity to be given to the price of meals, and forbid the (barging of prices higher than those so published; WhBBEAS it is expedient that the prices of meals or parts of meals, as well as the prices of beverages be posted at the door of restaurants and dining balls; It is ORDERED, therefore, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and (lame: That the following regulation be adopted: 1.{a) Any holder of a restaurant permit must post outside his establishment, near the main entrance door, the price of meals, portions of meals as well as the price of drinks; (6) the holder of a hotel permit must post outlide each dining hall, near the main entrance ur 1.Le Syndicat des Employe* Coiffeur* pom Daims de Québec, Inc.sera ajouté comme Donnes de Québec Inc.will he added sa con tract ins partie contractante «le deuxième part.party of the second part.2° L'exception concernant St-Edouard-dc- 2.In sul>scn 4.ssctîon 101.the exception Prampton (Dorchester) et St-Honoré, canton «le covering St.Edouard «le Prampton (Don hexter Shenlcy ilteaucc).apparaissant au paragraphe 4 and St.Honoré, Shenley «listrict (Beaucc .will de l'article loi, sera biffée, be deleted.3° L'article 113-B sera remplacé par le sui- 3, Section 113-B will be replaced by the vant: following: « 113-1$.Cher les coiffeurs pour «lames «les \"113-B.Every skilled lâches' hairdresser of zones I-A et 1 -H.le salarié qualifié qui a acctmi- /.ones I-A and I-B wh«) have two (2) years' pli deux (2) années de service continu au 30 continuous service on April 30th.including avril, y compris le temps fait comme apprenti, a apprenticeship time, is entitled t«» two 2 droit à «leux (2) semaines Consécutives «le va- successive weeks' vacation with pay.\" Cances payées.4° Le paragraphe « a » de l'article 135 sera 4.Subsection **#*' of section 135 will be super* remplacé par le suivant: seded by the following: Zone I Zone 11 '/.«ne /// le 1er janvier ./uni.1968 196H « a) Salaires H'ai/es: Employé réguliei\u2014 Regular employee: Coiffeur, catégorie « A * \u2014 Hairdresser, category \"A\".$50.00 $53.00 $45.00 s m no Coiffeur, catégorie « 11 \u2014 Hairdresser, category \"H\".45.00 4S.00 45.00 in 00 Manucure -.Manicurist.30.00 30.00 28.00 25 00 Apprenti-coiffeur pour dames \u2014 Apprentice ladies' hairdresser: 1er semestre-1st six months.10.00 10.00 14.00 12.00 de 7 à 12 mois inclusivement 7 to 12 months inclusively.22.00 24.00 20.00 18.00 de 13 à 18 mois inclusivement\u2014 13 to IS months inclusively 28.00 30.00 24.00 22.00 de 19 â 21 mois inclusivement - 19 to 21 months inclusively 31.00 33.00 .28.00 26 00 de 25 à 30 mois inclusivement;~ 25 to 30 months inclusively 30.00 3S.00 32.00 28.00 de 31 à 30 mois inclusivement.31 to 36 months inclusively 40.00 42.00 30.00 32 0\" Apprentie manucure \u2014 Apprentice manicurist: 1er trimestre \u2014 1st six months.15.00 15.00 15.(Ml 13.00 2e trimestre - 2nd six months.25.00 25.00 25.00 23 00 Employé temporaire ou remplaçant par jour \u2014 Occasional or substituting employee, (perday).10.00 10.00 10.Ou 8.00 ô° L'article 135, paragraphe « sera modifié \u2022\">.In section 135, subsection \"//' will lien y ajoutant l'aluu'a suivant: smended by the addition of the following paragraph : '< Cependant, la manucure compétente a droit \"However, à skilled manicurist is entitled to à une commission «le 35?«les recettes de son a 35% commission on the receipts of her work travail dépassant le double du salaire qu'elle that exece«l twice her actual wages, event hough reçoit même si tel salaire est supérieur au mi- such wages may be higher than the minimum nimuin fixé «lans le décret.» stipulated herein.\" 0° A l'article 136, l'horaire «le travail des 6.In section 130.hours of work forjolies I-A zones I-A et I-IJ sera remplacé par le suivant: and I-B will l>e replaced by the following: « Zones LA ct l-li \"Zones I-A and l-li Le lundi: chômé; Monday: non-working day; Les mardi, mercredi et jeudi: «le 9h «lu matin à Tuesday, Wednesday and Thursday: 9'it1,1 6.30hdu soir: to 0:30 p.m.; Le Vendredi: de 9h «lu matin à 9h «lu soir; Friday: 9:00 a.m., to 9:00 p.m.; I.e samedi: de S.30h du matin à Oh du soir; Saturday: 8:30 a.m.to 6.00 p.m.; Les 22, 23.29 et 30 décembre: «le Oh du matin December 22nd, 23rd.29th and 30th: 9*00 à Oh «lu soir.a.m.to 9:00 p.m.Exception: À compter «lu 1er janvier 19GS, Exception: Effective January 1, 1968, bean l'horaire «le travail sera «le S.30h «lu matin à of work: on Saturdays shall be from 8:30 a .to.te 5.30h «le l'après-midi le samedi.» 5:30 p.m.\" 7° L'exception apparaissant à la zone II «le 7.In section 130.the exception for BOtte H l'article 136 sera remplacée par la suivante: will l>e superseded by the following: « Cependant, dans la zone II-C (Montmagny), \"In zone II-C (Montmagny), hours'of work on l'horaire «le travail s'étend «le 8h du matin à Saturdays shall be from 8:00 a.m.to 12:00 noon, midi le samedi.\u2022 8° L'article 137 sera remplacé par le suivant: 8.Section 137 will be replaced by the following: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, J'JUr, Vol.09.So.15 2531 137.DABI les zones I-A et I-H, l'horuire dfl \"137.In zone» I-A and 1-15.hours of work on travail s'étend de Oh du matin ù 6.30h du soir le Wednesday arc from 0:0(1 a.m.to 6:30 p.m.mercredi durant les mois «l'avril, mai, juin et during April, May, June and December.Howev.décembre.Cependant, l'horaire de travail de er, on such days, the employer's and artisan's l'employeur et «le l'artisan peut être de Oh «lu hours «>f work may Ik- from '.\u2022:()() a.m.to 0:00 matin a 9h du soir pendant ces jours.\u2022 p.m.\" *i [/article 138 sera remplacé par le suivant: 9.Section 138 will be replaced by the follow.ing: 138.L'horaire «le travail s'étend «le 9h «lu \"I3S.On Wednesdays during April.May.malin à Oh «lu soir dans la zone I-C «-t de 8h June and December, as well as on December .lu malin à 9h «lu soir «lans les z«mes II et III le 21st, 22ml.23r«l, 28th, 120111 and 30th, hours of mercredi durant les mois «l'avril, mai, juin et uhlication «le cet avis dans la Gazette officielle \u2022If Québec, l'honorable Ministre «lu Travail recevra les objections en double copie, si possible, que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre du Travail.Don at Quimpkk.Ministère du Travail, é-rative « Association coopérative de consommation de Deux-Montagnes Two Mountains ( 'oustuiicr.s' Cooperative Association Le siège social de cette association coopérative esl situé à 124.Se Avenue, cité de Deux-Montagnes.Québec, clans le district électoral de Deux-Montagnes.Québec, le 7 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province.I0265-o Raymond Douville.Association coopérative d'habitation de Dolbean i Loi' (//-.s- associations coopératives) - Avis est donné que le secrétaire île la province a approuvé le changement de nom de l'association coopérative « La Société coopérative d'habitation île Dolbeau .en celui de « Association coopérative d'habitation de Dolbeau \u2022.Québec, le 10 avril 1907.Le Sous-sccrétaire de la province.19266-0 Raymond Douville.Avis divers Leon Abramovitch Avis est donné que Leon Abramovitch, gérant, de la ciré de Laval, «listrict «le Montréal, et résiliant à 1100, Shorecrest, présentera une requête au secrétaire «le la province de Québec pour obtenir un «lécret «lu lieutenant-gouverneur en conseil changeant, son nom de Léon Abramovitch à Léon Arnold, ledit changement de nom devant bénéficier à son épouse Dame Eisa Tenenbaum Abramovitch, de 1100, Shorecrest, cité de Laval, district de Montréal, et aux enfants qui naîtront.19134-14-2 Aldéric Roy Avis est donné que « Aldéric Roy », connu sous le nom de René Roy, présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil, pour changer son prénom « Aldéric * en celui «le « René », afin «l'être connu légalement comme étant René Roy.Montréal, 4 avril 1907.Le Requérant, 19209-14-2-o Aldéric Roy.Paroisse de Suiiit-Vineenl-dc-I'aul Avis est donné que Gérard-Marie Coderre, évêque «le Saint-Jean-dc-Québec, a, par «lécret du 13 novembre 1900, modifié les limites de la paroisse «le Saint-Vincent -de-Paul, à Jacques-Cartier.I9239-.» 2-00 Ark-.Ngin Chiang Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret numéro 927, du 31 mars 1907, Association coopérative de consommation de Deux-Montagne* Two .Mountains Consumers' Cooperative Association (('ooperative Associations Act) Notiee is hereby given that the Provincial Secretary has approved the format ion of the coo|X'rative association \"Association coopérative «le consommation de Deux-Montagnes Two Mountains Consumers' Cooperative Associa, tion\".The head ollice of this cooperative association is situated at 124, Nth Avenue, city of Two Mountains, Quebec, in the electoral district of Two Mountains.Quebec, April 7.1907.Raymond Douvillk, 19205 Assistant Secretary of the Province.Association coopérative d'habitation de Dolbeau (Cooperative .Associations Act) Notice is hereby given that the Provincial Secretary has approved the change of name of the cooperative association \"La Société coopérative «l'habitation «le Dolbeau\", to thai of \"Association coopérative d'habitation dé Doi* beau\".Quebec, April 10, 1907.Raymond Douville, 19260 Assistant Secretary of the Province.Miscellaneaous Notices Leon Abramovitch Notice is hereby given that Leon Abramovitch, manager, of the city of Laval, district of Montreal, ami residing therein at 1100 Shorecrest, will present a petition to the Secretary of the Province of Quebec for a «lecree of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Leon Abramovitch to Leon Arnold, said change of name to have application ami to ensure to the benefit of his wife Dame Eisa Tenenbaum Abramovitch of 1100 Shorecrest, City of Laval, «listrict of Montreal, and children to be born.19134-14-2-0 Aldéric Roy Notice is given that \"Aldéric Roy\", known under the name of René Roy, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council, to change his given name \"Aldéric\" to that of \"René\", so as to be legally known as René Hoy.Montréal, April 4, 1967.Aldéric Roy.19209-14-2-o Petitioner.Parish of Saint-Vincent-de-Paul Notice is hereby given that Gérard-Marie Coderre, bishop of Saint-Jean-de-Québec has.by a decree dated November 13.1966, changed the limits of the parish of Saint-Vincent-de-Paul, in Jacques-Cartier.19239-o -'\u2022'.«' Ark-Ngin Chiang The Lieutenant-Governor in Council has Urn pleased, by decree number 927, dated March 31, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1967, Vol.99, No.15 2535 d'effectuer Ifl changement de nom de Kai-Wen Lee i n celui de Ark-Ngin Chiang.Québec, le 6 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, I'.ijn.u Raymond Douvillk.Krwin Oravsky Brand Il ,i plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par l«- décret numéro 920, du 31 mars 1967, d'effectuer le changement de nom de Erwin Oravsky ocllli de Erwin Oravsky Brand.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, 19228*0 Raymond Douvillk.¦Steve Blouin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 925, du 31 mars 1907, d'effectuer le changement de nom de Joseph Jean-Guy Ix-pîtrc en celui de Steve Blouin.Québec, le 0 avril 19G7.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.Joseph René Cimichella Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret néinéro 929, du 31 mars 1967, d'effectuer le changement de nom de Giuseppe Cimichella en celui de Joseph René Cimichella.Québec, le (i avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.William Yoke-Koon Chiu Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 928.du 31 mars 1967, d'effectuer le changement de nom de Wei-Wing Jeu en celui «le William Yoke-Koon Chiu.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.Alfred Garbish Il a plu uu lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret numéro 930, du 31 mars 1967.d'effectuer le changement de nom de Alfred Uarbuss en celui de Alfred Garbish.Québec, le 0 mars 1907.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.King-Yim Gee il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret numéro 931, du 31 mars 1967, d effectuer le changement de nom de Gim-Chew Wong en celui de King-Yim Gee.Québec, le 6 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.Yen-Lip Lam Il ;» plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 932, du 31 mars 1967, 0 effectuer le changement de nom de Woy Lee en celui de Yen-Lip Lam.Québec, le 6 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-n Raymond Douville.1967, to effect the change of nume of Kai-Wen Lee to that of Ark-Ngin Chiang.Quebec, April 6.1967.Raymond Douvillk, 19228 Assistant Secretary of the Province.Krwin Oravsky Brand The Lieutenant-Governor in Council baa been pleased, by decree number 920, dated Man h 31.1907, to effect the change of name of Krwin Oravsky to that «>f Erwin Oravsky Brand.Quebec.April 0, 1907.Raymond Dou villi:.19228 Assistant Secretary of the Province.Steve Blouin The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 925, dated March 31.1907, to effect the change of name of Joseph Jean-Guy Lepttre to that of Steve Blouin.Quebec April 6, 1967.Raymond Douvillk.19228 Assistant Secretary of the Province.Joseph René Cimichella The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 929, dated March 31, 1907, to effect the change of name of Giusep|>c Cimichella to that of Joseph René Cimichella.Quebec, April 6, 1967.Raymond Douvillk, 19228 Assistant Secretary of the Province.William Yoke-Koon Chiu The Lieutenant-Governor in Council has been pleased by decree number 928, «latetl March 31.1967, to effect the change of name of Wei-Wing Jew to that of William Yoke-Koon Chiu.Quebec, April 0, 1967.Raymond Douvii.lk, 19228 Assistant Secretary of the Province.Alfred Garbish The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 930, dated March 31, 1967, to effect the change of name of Alfred Garbuss to that of Alfred Garbish.Quebec, March 0, 1967.Raymond Douvillk, 19228 Assistant Secretary of the Province.King-Yim Gee The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 931, dated March 31.1967, to effect the change of name of Gim-Chew Wong to that of King-Yim Gee.Quebec, April 6, 1967.Raymond Douvillk, 19228 Assistant Secretary of the Province.Yen-Lip Lum The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by decree number 932, dated March 31, 1967, to effect the change of name of Woy Lee to that of Yen-Lip Lam.Quebec, April 6, 1967.Raymond Douvillk, 1922S Assistant Secretary of the Province. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, lô avril 1907, 99' année, n° l;> 2m William Land) Il a plu au licutcnunt-gouvcrncur eu conseil, par le décret numéro 933, «lu 31 mars 19671 (l'effectuer le changement «le nom «le Wasy) Lazaskie en celui «le W il liai n Landy.Québec, le 6 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, 1922841 Raymond Douvillk.Call Joui li\".Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil par le «livret nuinéro 934, «lu 31 mars 1907, (l'effectuer le changement «le nom «le Jime Hong l.ee en celui «le (îah Juin Loo.Québec, le (i avril 1907.Le Snu.i.\\ecrétuire de la province, 19228-n Raymond Douvillk.Irving Narvey Il a plu au lieutenant-gouverneur eu conseil, par le décret numéro 935, «lu 31 mars 1907, d'effectuer le changement «le nom «le Irving N'arovlansky en celui «le Irving Xarvey.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, I922s.«> Raymond Douvillk.Vlexander Nicholas Olyarchuk Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 930, «lu 31 mars 1907, «l'effectuer le changement «le nom «le Alexamler Nicholas Olejarchyk en celui «le Ak'xamler Nicholas Olyarchuk.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.Joseph Jacques Gilles Parent Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 937.«lu 31 mars 1907, d'effectuer le changement «le nom «le Joseph Jacques Gilles Deseheneaux en celui «le Jos«>ph Jacques Gilles Parent.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de ki province, 19228-u Raymond Douvillk.Sydney Ross Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret numéro 938, «lu 31 mars 1907.d'effectuer le changement «le nom «le Sydney Uotlcnl>crg en celui de Sydney Ross.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, I922S-0 Raymond Douvillk.Hurry Skurnik Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 939, du 31 mars 1907, d'effectuer le changement de nom de Harry Ralph Slikurnik en celui «le Harry Skurnik.Québec, le 0 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province.19228-0 Raymond Douvillk.Albert Solomon Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le «lécret numéro 940, «lu 31 mars 1967, d'effectuer le changement «le nom de Albert K i effect the change of name ni W'ajyl La/.askic to that of William Landy.Quelle, April 0.1907.Raymond Dou ville, 19228 Assistant Secretary of the l'rm n Gah Join l.oo The Lieutenant-Governor in Council lut* been pleased, by decree n umber 934.dated Mardi 31, 1907, to elfeet the change of name ol Jime Hong Lee to that of (Jab Join Loo.Quebec, April 6, 1907.Raymond Douvii.i.i.1922s Assistant Secretary or the Prot 'net Irving Narvey The Lieutenant-Governor in Council has been pleased, by «leeree number 935, dated Mardi SI, 1907, to effect the change of name of Irving N'arovlansky to that of Irving Narvey.Quebec, April 0.1907.Raymond Douvii i.i.1922S Assistant Secretary of the Product Alexander Nicholas Olyarchuk The Lieutenant-Governor in Council lia* been pleased, by «leeree number 930, dated Mardi 31, 1907, to effect the change of name of Alexander Nicholas Olejarchyk to that of Alexander Nicholas Olyarchuk.Quebec.April 0, 1907.Raymond Douville, 1922s Assistant Secretary of the Province.Joseph Jacques Gilles Parent The Lieutenant-Governor in Council ba* lieen pleased, by «leeree number 937, dated March 31.1907, to effect the change of name of Joseph Jacques Gilles Deseheneaux to that f Sydney Rottenberg to that of Sydney Ross.Quebec, April 6, 1907.Raymond Douvii.i.i .I922S Assistant Secretary of the Provint' Harry Skurnik The Lieutenant-Governor in Council ba* lieen pleased, by decree number 939, dated Mareli 31, 1967, to effect the change of name «»f Harry Ralph Shkurnik to that of Harry Skurnik.Quebec, April 0.1907.Raymond Douvii.i.i 1922S Assistant Secretary of the l'roi'm.- A liter t Solomon The Lieutenant-Governor in Council ba* lieen pleased by decree nuinU-r 940, dated March 31, 1967, to effect the change of name of Albert Krockmalnik, to that of Albert Solomon.Quebec, April 0, 1907.Raymond Douvii.i.i .1922S Assistant Secretary of the Promt in QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 10, 1907, Vol.99, So.lô 2537 Aiiloniu Valade || a pltl all lie ilk-ii ant-gouverne ni' I'll conseil, par le décret numéro 941, «lu 31 mars 1967, d'effectuer le changement «le nom «le Antonina Weiilinehoules en celui «le Antonia Vala«le.Québec, le 6 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-e Raymond Douvillk.Joseph George Valade Il a plu au lieutenant-gouverneur eu conseil, par le «hVret numéro 942, «lu 31 mars 1967.(jl'effectuer le changement «le nom «le Jurgis .luo/.a- \\'alen«4ninas en celui de Joseph (îeorge Valade.Québec, le 6 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, I922S o Raymond Dou ville.Joseph Paul Valade 11 a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 943, «lu 31 mars 1967, d'effectuer le changement «le nom «le Joseph Paul VYallanee en celui de Joseph Paul Valade.Québec, le 6 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, 19228-0 Raymond Douvillk.Vlexander Maslowski Avis «\u2022>! ici donné que M.Alexander Maslowski, opérateur, domicilié au 517, boul.Saraguay, Pierrefbnds, Québec, son épouse Carolyn, ménagère, et son fils Daniel, s'adresseront au secrétaire «!«¦ la province de Québec en vertu «lu Bill 31 pou: changer leur nom comme suit: M.Alexander Marlowe, son épouse, Carolyn Marlowe el son fils Daniel Marlowe.Montréal, le 21 mars 1967.19260-15-2-o Alexander.Maslowski.Paroisse de Saint-Mary Avis eat «lonné que Gérard-Marie Coderre, évêque , constituée en corporation le 1er septembre 1001, à compter du 11 avril 1967.I.e Sous-secrétaire de la province, Rav.monn DorviLl.e.l!L>LNu 14197-01 Paul Dallain Company Limited l'aul Dallain Compagnie limitée Avis est donné qu'en vertu de lu Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Paul Dallain Company Limited - Paul Dallain Compagnie limitée », constituée en corporation le 4 janvier 1950, à compter du 14 avril 1907.I.e Sous-secrétaire de la province.Raymond Dor ville.19228-0 9491-49 Ruby Poo's Enterprises Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Ruby Poo's Enterprises Ltd.», constituée en corporation le 12 avril 1900, à compter du 14 avril 1987.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dor ville.19228-0 11520-09 Forward Look Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Forward book Inc., constituée en corporation le 13 décembre 1955, à compter du 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de lu province.Raymond Dor ville.19228-0 13413-55 Hen («rosser Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Ben Grosser Holdings Ltd.», constituée en corporation le 29 juin 1904, à compter du 14 avril 19117././¦ Sous-secrétaire de la province.Raymond Dor ville.19228-0 2778-04 Kaz of Canada Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Kaz of ' snada Ltd.», constituée en corporation le 22 mai 1958, à compter du 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Dor ville.19228-u 11336-58 l.aurentien Lefebvre & Fils limitée Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d accepter l'abandon de la charte de « Laurentien Lefebvre & Fils limitée », constituée en corporation le 10 septembre 1950.à compter du 14 «vril |%7.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.'w228.0 12698-56 La Compagnie du Vallon ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"La Compagnie du Vallon ltée\", incorporated on September 1st, 1901, on and from April 14.1987.Raymond Dor ville.Assistant Seeretari/ of the Province.19228 14197-l il Paul Dallain Company Limited Paul Dallain Compugnic limitée Notice is given that, umler the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter Ol \"Paul Dallain Company Limited Paul Dallain Compagnie I i ni i tee\", incorporated on .lailliarv I.1950, on and from April 14.1967.Raymond Dor ville.Assistant Seeretari/ of the Province.1922S 9491-49 Ruby Foo's Enterprises Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Ruby Foo's Enterprises Ltd.\".incorporated on April 12, 1900.on and from April 14.1907.Raymond Dou ville, Assistant Seeretari/ of the Province.1922s 11526-60 Forward Look Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Forward Look Inc.\", incorporated on December 13.1955, OU and from April 14.1967.Raymond Dot villi:.Assistant Seeretari/ of the Province.1922s 13413-55 Ben Grosser Holdings Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Ben Grosser Holdings Ltd.\".incorporated on June 29, 1904.on and from April 14.1907.Raymond Dor villi:.Assistant Seeretari/ of the Province.1922s » 2778-04 Kaz of Canada Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Kaz of Canada Ltd.\".incorporated on May 22.1958.on and from April 14.1907.Raymond Doiville.Assistant Seeretari/ of the Province.I922S 11336-58 Laurentien Lefebvre & Fils limitée Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter ol* \"Laurentien Lefebvre & Fils limitée\", incorporated on September 10.1950, on and from April 14.1907.Raymond Dor villi:.Assistant Seeretari/ of the Province.1922s 12698-56 2540 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 avril 1007, 90' année, n° 15 l.orniiiii Realty Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Loriuan Realty Inc.', constituée en corporation le 5 mars 1059, à compter du 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.1922-S-o 11301-59 Montbeliard ltée Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte «le « Mofitbe-liard ltée », constituée en corporal ion le S juin 1080, à compter du 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.l922s-o 13105-59 Olympic Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon «le la charte «le « Olympic Associates Inc.», constituée en corporation le 19 novembre 1959.à compter «lu 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.1922S.o 10332-59 Perri-Ann Lingerie inc.Avis est donné qu'en vertu «le la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon «le la charte «le « Perri-Ann Lingerie inc.», constituée en corporation le 17 septembre 1905, à compter du 14 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.I9K2S.o 3761-05 Lomian Realty Inc.Notice is given that, umler the CoJUlttniei Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter «>f \"Lonnifl Realty Inc.\", incorporate«l on March *>.1959, on and from April 14, 1907.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Province.10228 1190141 Montbeliard ltée Notice is given that, under the Companies Ad, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"'Mont, beliai-tl ltée\", incorporated on June S.1959, on and from April 14, 1007.Raymond Doi\u2022 villi .Assistant Secretary of the Province.1922s 1310549 Olympic Associates Inc.Notice is given that, umler the Comiianief Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"< Mympii-Associates Inc.\", incor|>orate«l on November I!'.1959.on and from April 14.1907.Raymond DOUVILLK.Assistant Seeretari/ of the Province.1922s 1633249 Perri-Ann Lingerie inc.Notice is given that, under the ( onipaine-Act, the Provincial Secretary has been plcssed to accept the surrender of the charter of '\"Perri-Ann Lingerie inc.\", incorporated on September 17, 1905, on an«l from April 14, 1907.Raymond Dor villi .Assistant Seeretari/ of the Province.1922s 3761-63 Rainbow Vending Machines Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, il a plu au secrétaire de la province d'accepter l'abandon de la charte de « Rainbow Vending Machines Inc.», constituée en corporation le 12 juillet 1902, à compter du 14 juillet 1907.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.I022S-o 12035-62 Sociéta Femminilc Caserta Cascrta Femminilc Society Avis est donné qu'en vertu «le la Loi des compagnies, il a plu au secrétaire de la province «l'accepter l'abandon «le la charte de « Sociéta Femminilc Caserta \u2014 Cascrta Fcmminile Society », constituée en corporation le 3 août 1938, à compter du 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.I022S-o 1563-38 Sunnyside Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de la Im'i «les compagnies, il a plu au secrétaire «le la province «l'accepter l'abandon de la charte de « Sunnyside Holdings Limited », constituée en corporation le 29 mars 1950, à compter «lu 14 avril 1907.Le Sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douvillk.10228-o 10900-50 Rainbow Vending Machines Iiu-.Notice is given that, under the Companies Act.the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Rainbow Vending Machines Inc.\", incorporated an July 12.1902.on and from April 14, 1067- Raymond Douvii.i.i Assistant Seeretari/ of the Protina.1922s 1203542 Sociéta Femminile Caserta Caserta Femminile Society Notice is given that, under the Companies Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Sociéta Femminile Caserta \u2014 Caserta Femminile Society\", incorporated on August 3, 1038, on and from April 14, 1907.Raymond Douvii.i.i.Assistant Secretary of the Protinct.1922S 156348 Sunnyside Holdings Limited Notice is given that, under the CompaniM Act, the Provincial Secretary has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Sunny-side Holdings Limited\", incorporated on March 29, 1956, on and from April 14, 1967.Raymond Douvii.i.i.Assistant Secretary of the Provinct.10228 101)0046 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1967, Vol.99, Ko.15 2641 Compagnies autorisées Companies Licensee! à faire des affaires to do Business American Technoimpex Ltd.Avig ait donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « American Technoimpex Ltd.», a été autorisée à faire affaires: dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Reginald C.Harvey, 035, ouest, boulevard Dorchester, Montréal.I.e bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1121-1123, ouest, rue Ste-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10228 12-67\u2014 1359-111) kurt Salmon Associates, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Kurt Salmon Associates, Inc.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite coin-pagnie, est M.André Desjardins, de 81, rue St-Pierre.suite 42, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 81, rue St-Pierre, suite 42, Québec, district judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douville.19228 11-67\u2014 1359/137 Car ter-Wallace N.S.Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies étrangères, la compagnie « Carter-Wallace X.S.Inc.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Donald W.Sutherland, de Mont Royal.be bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 5485, rue Ferrier, Mont Royal, «listrict judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19228 10-67 \u2014 1359/128 Rodell Corporation (1967) Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Rodell Corporation (1967) Limited », a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite com-pagnie, est M.David Henry Holland, 555, avenue Curzon, St-Lambert.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à suite 700, édifice de la Banque Royale, 1, place Ville Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.MBS 8-67\u2014 1359/136 Northland-Crawford Insurance Adjusters, Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « North- American Technoimpex Ltd.Notice is given that, umler the Extra-Provincial Companies Act \"American Technoimpex Lbl.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Reginald C.Harvey, of 635 Dorchester Boulevard West, Montreal.The principal oflice of the company in the Province is at 1121-1123 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.19228-c) 12-67\u2014 1359/11'.» Kurt Salmon Associates, Inc.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Kurt Salmon Associates.Inc.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.André Desjardins, of 81, rue St-Pierre.Room 42, Quebec.The principal office of the company in the Province is at 81, rue St-Pierre, Room 42, Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.19228-0 11-07- - 1359/137 Carter-Wallace N.S.Inc.Notice is given that, umler the Extra-Provincial Companies Act, \"Carter-Wallace N.S.Inc.\", has l>cen authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Donald W, Sutherland, of Mount Royal.The principal office of the company in the Province is at 5485 Ferrier Street, Mount Royal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.19228-0 10-07\u2014 1359/12s Rodell Corporation (1967) Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Rodell Corporation (1907) Limited\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receicing services in proceedings aginst the company is Mr.David Henry Holland, of 555 Curzon Avenue, St-Lambcrt.The principal office of the company in the Province is at Room 700.The Royal Rank Building, 1 Place Ville Marie, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.10228-o 8-07\u2014 1359/136 Northland-Crawford Insurance Adjusters, Inc.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Northland-Crawford Ins- 2642 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, là avril 1907, 99' année, n° ln land-Crawford Insurance Adjusters, Inc., a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations duns les procédures contre ladite compagnie, est M.André Desjardins, SI, rue St-Pierre, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 81, rue St-Pierre, Qué!>ce, \u2022listrict judiciaire de Québec.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doi;ville.10228 20-07 1864/28 urance Adjusters, Inc.\", bus been authorized l\u201e carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiciuj services in proceedings against the company is Mr.André Desjardins, 81 St.Pierre Street, Quebec.The principal ollice of the company in tlu-Province is at 81 St.Pierre Street, Quebee, judicial district of Qucl>cc.Raymond Doi villi .Assistant Secretary of the Province.18228-0 20-07 1364/23 Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of Vssociation of English-Speaking Interns of Montreal Avis est par les présentes donné que I'« Association of English-Speaking Interns of Montreal ».une corporation constituée sous la troisième partie «le la Loi des Compagnies et ayant son siège social en la cité «le Montréal, s'iulressera au Secrétaire de la province de Quél)ec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte sous les provisions de la Loi des Compagnies.Daté à Montréal, Québec, ce 4e jour «favril 1907.Le Secrétaire, 19234-0 Marc Goldstkin.Association of Knglish-Speakiii;: Interns of Montreal Notice is hereby given that the \"Association «>f English-Speaking Interns of Montreal\", a corporation incorporated umler Part III of the Companies Act and having its bead ollice in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Quebec tor leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal.Quebec, this 4th .lay of April.1907.If abc Goldstein, 18284-0 Secretary.Montreal Terra Cot ta Limited Avis est par les présentes donné que « Montreal Terra Cotta Limited », une compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social dans la cité de Montréal demandera au Secrétaire de la province «le Québec l'autorisation de renoncer à sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de Québec.Signé à Montréal, ce 31c jour de mars 1907.(Sceau) La Secrétaire, Thérèse Bénard.19238-0 1473-36 Montreal Terra Colla Limited Notice is given tliat \"Montreal Terra Cotta Limited\", incorporated in virtue of the Quebec Companies Act ami having its head office in the city of Montreal, will apply to the Provincial Secretary of Quebec for leave to surrender ib charter pursuant to the provisions of the Quebec Companies Act.Signed at Montreal, this 31st day of March, 1967.(Seal) Thérèse Bex aril Secretary.19238 1473-36 Hampstead Terrace Ltd.Avis est donné que la compagnie < Hampstead Terrace Ltd.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte et son annulation à compter d'une date qu'il lui plaira de fixer.Hampstead Terrace Ltd., Par le Président, 19245 David Azrieli.Hampstead Terrace Ltd.Notice is hereby given that \"Hampste.nl Terrace Ltd.\", a corporation constituted under the Quebec Companies Act ami having its head office in the city of Montreal, will apply to the Secretary of the Province of Quebec for the acceptance of the surrender of its charter ami its cancellation on ami from a date to In- li\\«'f National Societies Act and «>f section 225 ol the < 'oinpanies Act.Raymond DoUVILI i Assistant Seeretari/ of the I'm 192 IS 1147 Calé Tropicaua inc.Notice is given thai \"Café Tropicaua inc.\", has changed the number «»f its directors from .\".to I.Irene P.Gavdbbai lt.Secretary.19268-0 14851-61 Century Automotive Corporation Notice is given that \"Century Automotive Corporation\", has changed the number of it-directors form 3 to I.Ski.ma Lewovitz, Secretary.19260-O 30347 Mouvement récréatif de Notre-l)ame-du-Saeré-Coeur Notice is beregy biven that \"Mouvement récréatif de Notre-Dame-du-Sacré-Coeui¦\".au changed tlie number «>f its directors from :> t.7.Lucien Raymond, Presidi nt.19270 14077-62 Mouvement récréatif de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on September 22, 1900, approved the general by-l\\vas of \"Mouvement récréatif de NOtre-l )aine-du-Sacré-C«)eur\".and such, in pursuance to section 225 of the Companies Tct.Raymond Dorvii.i.i .Assistant Seeretari/ of the Province.19270 11077-62 Place Bonaventure inc.Notice is hereby given that \"Place Bonaventure inc.\", has changed the number of its directors from 8 to 10.Msa Jink Gagnon, Secretary.19271-0 86344 Laboratoire Cherrier limitée Notice is hereby given that the cancellation of the «\u2022harter «)f \"Lalsmitoire Cherrier limitée .was revoked by the Lieutenant-Governor ol the Province of Quebec on April 3,1907.Raymond Dorvu.i.i Assistant Seeretari/ of the Provinei 1922s 1192740 Imprimerie des Forges ltée Notice is given that \"Imprimerie des Forges ltée\" has changed the number of its dir-elor-frtnn 5 to 7.R.Lamontaoni Secretary.19292 16417-52 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April iô.tm, Vd.99, Xo.10 2545 Yilhois Lumber Ltd.Yilhois Lumber Ltd.Avis esl donné ejus 1» compagnie ^ \\'ill>oi.s Notice is given that \"Vilbois Lumber Ltd.\".Lumber Ltd.», a changé le nombre «le ses admi- bas changed the number of its directors from 1 \u201e,.i iteurs de 4 à 3.t«» 3.Le Secrétaire-trésorier, NoitM anD Pkhhon, Noii\\i and Peuuon .Seeretaru-Trcasurcr.19293-u 14533-61 1929:5 14533-61 Vente d'effet non-réclame* Sale of Unclaimed Baggage l.a Gie des Messageries Canadien Pacifique A via est par les présents donné «pic tous les effel - reçus avant le 1er jour «le mai 1966, et non réclamés aux bureaux «les Messageries Canadien Pacifique, à «livers endroits «le la province «le Québec, seront vemlus aux enchères puhlupics au l»ln< haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur, 128 est, rue King, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 4c jour de mai 1997, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Québec.Que., le 20 mars 1967.Le Surintendant général, 19010-12-6-O E.M.Tiikashek.Canadian Pacifie Kxprcss Company Notice is hereby given that all goods received previous to the 1st «lay of May 1900, an«l still remaining unclaimed in the oliices of the Canadian Pacific Express Company, at different points in the Province of Quebec, will be sohl at public auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 128 King Street Bast, Toronto, Ontario, at 11:00 o'clock in the forenoon, on the 4th day of May 19(57, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Quebec, Que., March 20, 1967.E.M.TlIItASHEK.19040-12-6-o General Superintendent.Demandes à la Législature Applications to Legislature l.c«/-ommissaircs de la Commission des Ecoles Catholiques de Sherbrooke Avis public est par la présente «lonné par les commissaires de la Commission des Ecoles Catholiques «le Sherbrooke, dans le comté «le Sherbrooke, qu'ils «adresseront à la Législature île la Province «le Québec, à la présente session, pour l'adoption «l'une loi visant les buts suivants: Amendes l'article 3 «le la Loi 9-10 Elizabeth II.1960-61, afin de le remire plus clair et moins susceptible dc contestation: MODIFIER l'article 4 de ladite loi afin d'éviter les contestations et interprétations compliquées en laissant tomber définitivement toutes les législations d'exception qui pouvaient affecter antérieurement la Commission des Ecoles Catholiques de Sherbrooke; Amender l'article 10 de ladite loi afin «le porter de «piatre à six le nombre «les quartiers pour lins d'élection scolaire dans la municipalité scolaire de Sherbrooke; Modifier les articles 11 et 12 de ladite loi, afin de les faire concorder avec l'établissement de nouveaux quartiers en portant le nombre de commissaires de langue française de quatre à ïix; Modifier l'article 13 de ladite loi en disant clairement que le commissaire «le langue anglaise \u2022\u2022\u2022\u2022ra élu par la majorité des électeurs «le langue anglaise de la municipalité scolaire de Sherbrooke; Modifier l'article 14 «le ladite loi afin «le permettre que les commissaires actuels restent \u2022\u2022a fouet ion jusqu'au deuxième mandat vu le passage «lu nombre «le commissaires de «piatre a six; lb inplacer le présent article 15 par un article déterminant dans quel ordre se feront les prochaines élections scolaires de la municipalité scolaire «le Sherbrooke vu l'augmentation du nombre «le quartiers; Abroger l'article 17 qui créait pour la Commission dos Écoles Catholiques de Sherbrooke 1 article 154 A de la Loi de l'Instruction Publique School Commissionners of the Catholic School Hoard of Sherbrooke Public notice is hereby given by the school Commissionners of the Catholic School Hoard of Sherbrooke, in the county of Sherbrooke, that they will apply to the Provincial Legislature presently in session to get the adoption of a law in order: To amend section 3 of Act 9-10, Elizabeth II.1960-01 so it is clearer and less susceptible of «lifficult interpretations; To modify section 4 of the said act so to avoid difficult interpretations by definitely droping all previous special laws affecting the Catholic School Board of Sherbrooke: To amend section 10 of the sai«l act in onler to bring from four to six the number of wards for school election purposes; To modify sections 11 and 12 of the said act so they correspoml to the new number of wards; To modify section 13 of the said act so to state more clearly that the english language com-missionner school be elected by the majority of the english speaking electors of the whole territory falling under the jurisdiction of the Catholic School Board of Sherbrooke; To modify section 14 of the said act so that the present commissionners shall remain in office until the second monday of June following the expiration of their mandate in order to permit the proper passing from four to six french language commissionners; To replace the present section 15 of the said act a new section stating in what order shall the coming school elections l)c done because of the new number of wards; To repeal section 17 of the said law pertaining to the general meeting of electors and to replace it by an article of a new nature saying that a 2540 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 avril 1907, 99' année, it° 15 relatif à une assemblée générale de tous les électeurs en le remplaçant par un article de nature nouvelle disant qu'un candidat ne peut être mis en candidature que pour le quartier où il est domicilié depuis au moins douze mois; Abroger le présent article 18 relatif aux devoirs «le l'officier chargé «le présider l'assemblée «les électeurs et «le le remplacer par un article «le nature nouvelle permettant une nouvelle augmentation «lu nombre de commissaires advenant le cas de fusion ou d'annexion suivant le bon plaisir «lu Lieutenant-Gouverneur en conseil; Abroger l'article 19 relatif aux dates d'élections scolaires, ces dates «levant désormais être «\u2022elles prévues à la Loi «le l'Instruction Publique; Modifier l'article 20 en se reportant à la loi générale quant aux dates de fabrication «le la liste électorale; Modifier l'article 22 afin «l'y ajouter un paragraphe permettent «pie lorsque le secrétaire de la Commission «loit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans en publier le texte entier, mais en faisant connaître seulement la nature, les contribuables pouvant en prendre connaissance à son bureau; Remplacer l'article 24 par un nouveau texte amendant l'article 373 de la Loi «le l'Instruction Publique permettant «le prendre le rôle d'évaluation de Sherbrooke afin «le niveler les rôles d'évaluation «les municipalités recouvertes par le territoire de la Commission «les Écoles Catholiques de Sherbrooke; Abroger l'article 25 exemptant «le taxes scolaires l'huile utilisée pour fins domestiques cette taxe étant maintenant «lésuète; Modifier l'article 32 en y incluant la liste «les immeubles appartenant à des compagnies ou à des corporations; Abroger l'article 33 prévoyant la division de la taxe prévue sur les immeubles appartenant à des compagnies ou des corporation entre la commission scolaire catholique et la commission scolaire protestante, la commission se référant désormais à la Loi générale quant à cette «listri-bution; Abroger l'article 37 traitant de l'application «les taxes qui proviennent des immeubles appartenant à des compagnies ou des corporations, la Commission se référant dorénavant à la Loi de l'Instruction Publique.Sherbrooke, ce 15e jour de mars 1967.Les Procureurs de la pétitionnaire.foutin, rouillahd, G obei l 18981-12-4-o & Coulombe.Marie Êvangéline Pelland Avis est donné que « Marie Êvangéline Pelland », ménagère, veuve de Jean-Charles Harvey, des cité et district de Montréal, a déposé devant la Législature de Quél>ec, en session, une proposition de loi ayant pour objet de faire déclarer que le terme « légitime », dans le testament de feu Albert J.Pelland, daté le 5 décembre 1956, inclut Francis Axel Harvey, fils adoptif de ladite Marie Êvangéline Pelland et dudit feu Jean-Charles Harvey.19085-13-4-O Ville de Baie-Comeau Avis public est par les présentes, donné, que la Ville de Baie-Comeau s'adressera à l'Assemblée Législative de la Province de Qucliec, à sa session courante, en vue d'obtenir une loi dont l'objet candidate can put his candidature only in the ward where he lias been domiciled for at least twelve months; To repeal section 18 of the said act pertaining to the duties of the officer presiding the meeting of electors and to replace it by an article of a new nature permitting to increase the number of commissioners upon annexation, with the permission of the Lieutenant-Governor in < nun-cil; To repeal section 19 pertaining the date of elections such date being determined by the Education Act; To modify section 20 of the said act pertaining to the dates of the drafting of the list of elector! so it corresponds to the new dates of elections; To modify section 22 of the said act this permitting that whenever the secretary of the Catholic School Board of Sherbrooke must give notices of a resolution he is authorized to do so without publishing the entire texte, but by making know only the nature of the resolution and inviting the ratepayers to take cognition of the resolution at his office; To replace section 24 of the said act by a new-section amending article 373 of the Education Act so to permit to take the valuation roll of the city of Sherbrooke as a basis for reestablishing the valuation roll of municipalities covered by the territory under the jurisdiction of the Catholic School Board of Sherbrooke; To repeal section 25 of the said act which permitted the Board to exempt from all Education taxe oil used for domestic purposes, since this section no longer applied ; To modify section 32 by including the list of immoveable properties belonging to companies or corporations; To repeal section 33 pertaining that taxation of real estate belonging to corporations or companies legally incorporated, the Board now following the Education Act on that matter: To repeal section 37 of the said act pertaining that taxes providing for on the immoveables belonging to companies and corporations, the Board being henceforth following the provisions of the Education Act on that matter.Sherbrooke, this 15th day of March, 1907.fortin, rouillard, G obei I.& coulombe.18981-12-4-o Attorneys for Vie petitioners.Marie Êvangéline Pelland N'otice is hereby given that \"Marie Evangéline Pelland\", housewife, widow of Jean-Charles Harvey, of the city and district of Montreal, has applied to the Quebec Legislature, in session, to have the term \"legitimate\", in the will «>f the late Albert J.Pelland, dated on DecernluT à.1956, include Francis Axel Harvey, adopte»I son of the said Marie Êvangéline Pelland and of the said late Jean-Charles Harvey.10065-13-4 Town of Baie-Comeau Public notice is hereby given that the town of Baie-Comeau will apply to the Legislative Assembly of the Province of Quebec, during its present session, to obtain a law, the purpose »>f QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1007, Vol.90, No.15 mt§ .lanK-mler su charte, pour lui accorder les pouvoirs additionnels nécessaires à la bonne gdniiuistratiou «le ses affaires: 1.Pour |h)iivoir accorder un octroi annuel jusqu'à concurrence de vingt mille dollars et au delà '! lots 40 à 45 inclusivement du rang I du canton «le Cawood.3.toute la municipalité civique de Portage \u2022lu Fort.i elle nouvelle municipalité soclaire sera administre.- par sept commissaires, conformément à I article 91 de la Loi de l'Instruction Publique.(elle nouvelle municipalité scolaire, aux fins détection, conformément à l'article 54a de la Loi i|c l'Instruction Publique sera divisée en quatre quartiers décrits et représentés comme -ml : Quartier No 1: comprenant le territoire de la municipalité civique du village de Shawville, '\"\u2022\u2022ix membres; Quartier Xo 2: comprenant le territoire décrit 'laiis |a description ci-dessus mentionnée au numéro 1 moins le village de Shawville, trois membres; Department of Education Clarendon-Portage du Fort and Thorne Application is made to unite the school municipalities of: Clarendon, Portage du Fort and Thorne all in the county of Pontiac and erect their territory into a separate school municipality, for Protestant school purposes only, under the name of \"Central Pontiac\", in the county of Pontiac.The territory of this new school municipality is described as follows: 1.the whole of the township of Clarendon; lots 20, 27 and 28 of range IV, the northern half of lot 25 of the same range and lot numlier 1 of range I in the township of Litchfield; lots 1 to S inclusive of range I, 1 to (i inclusive of range II and 1 to 4 inclusive of range III, all in the township of Bristol.2.the whole of the townships of Thorne and Aldfield; lots 40 to 45 inclusive of range I of the township of Cawood.3.all of the civic municipality of Portage du Fort.This new school municipality will be administered by seven commissioners in accordance with section 91 of the Education Act.This new school municipality, for election purposes, in accordance with section 54a of the Education Act, will lie divided into for wards described and represented as follows: Ward Xo.1 : comprising the territory of the civic municipality of the village of Shawville, two members; Ward Xo.2: comprising, the territory described in the above mentioned description number 1 less the village of Shawville, three members; 2548 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, Jô avril 1907, 99' année, n° 15 Quartier No 8: comprenant le territoire décrit dans lit description numéro 2 ci-dessus mentionnée, un Membre; Quartier No I: comprenant le territoire mentionne «lans la description «-i-dessus au numéro 3, un membre.Le 29 mars MM'»7.Le Ministre de l'Education, 19119-14-2 J e an - J a c ql'es BkUTUAND.Campbell's Hay (Prot.), Mansfield (Prot.) I.< -lie et Waltbam, Diss.Demande est faite d'unir les municipalités scolaires de Cambell'i Bay (l'rot.), Mansfield (l'rot.), Leslie et Wallhain, diss., toutes dans le comté de Pontiac, «-t d'ériger leur territoire en une municipalité scolaire «listincte aux fins «les écoles protestantes seulement, sous le mon de i Pontiac County West », «lans le comté «le Pontine.Le territoire «le cette nouvelle municipalité scolaire est décrit comme suit: 1° le canton entier de Grand Calumet, le canton entier de Litchfield, moins: la municipalité civique «lu village «le Portage du Fort, la moitié nord «lu lot 2f> du rang IV, les lots 27 et 28 «lu même range! le lot l du rang I, les lots 1 à 2ti inclusivement «lu rang XI, les lots 1 à i) inclusivement des rangs 10, 9, 8, 7.0 et 7, 8 el 0 «lu rang V.2° le canton entier «le Mansfield, et les lots 1 à 0 inclusivement «les rangs XL X.IX, VIII, VII et VI, et les lots 7.8 et 0 «lu rang V «lu canton de Litchfield.3° le canton entier «le Leslie, et les lots 10 à 2S inclusivement «lu rang XI du canton de Litchfield et les lots 39.-10, 41 et 45 «lu rang I du canton «le Clapham.\u20221° le canton entier «le Walt ham et les lots b, e et «1 «lu rang II et b.e du rang III «lu canton de ( 'hiclu'ster.Cette nouvelle municipalité scolaire sera administrée par 7 commissaires conformément à l'article Xo 91 «le la Loi «le l'instruction publique.Cette nouvelle municipalité scolaire, pour fins «l'élection, conformément à l'article 54a de la Loi «le l'instruction publique, sera «livisé en 4 quartiers, un pour chacune «les descriptions ci-haut mentionnées (Xo 1, 2, 8, 4.) et représentés comme suit: Quartier Xo 1 2 membres; Quartier Xo 2 - 2 membres; Quartier Xo .\"1 \u2014 2 membres; Quartier No 4 \u2014 1 membre.90 mars 1997.Le Ministre de l'Éducation, 19150-14-2 Jean-Jacques Bertrand.Sain te-Madclcine Demande est faite d'annexer la municipalité scolaire «le Sainte-Madeleine, dans le comté «rOutremont, à la municipalité scolaire «le la cité d'Outremont, «lans le comté «l'Outremont.Québec, le 3 avril 1967.Le Ministre de l'Education, 19207-14-2-o Jean-Jacques Bertrand.Ward Xo.3: comprising the territory described in the above mentioned description number L\\ one memhen; Ward Xo.4: comprising the terril on men.turned in the above description number 3, one member.March 29, 19G7.Jean-Jacques Bertrand, 10149-1 l-2-o M inister of Educat >¦ », Campbell's Bay (Prot.), Mansfield (Prêt) Leslie and Waltbam, Diss.Application is made to unite the school muni.cipalities «>f Campbell's Bay (Fret.), Masheld (Prot.), Leslie and Walt ham, diss., all m the county of Pontiac and erect their territory into a separate school municipality for Protestant school purposes only, under the name of \"Pontine County West\", in the county of Pontiac.The territory of this new school municipality is described as follows: 1.the whole of the Township of Grand Calumet, the wlude Township of Litchfield, less: the Civic Municipality of The Village of Portage da Fort, the northern half of lot 25 of range IV.lots 27 and 2«S of the same range and loi 1 of range I, loti 1 to 20 inclusive of range XI, loti 1 to 9 inclusive of ranges 10, 9, 8, 7, 6 and 7.8 ami 9 of range V.2.the whole of the Township of Mansfield, and lots 1 to 9 inclusive of ranges XI, X, IX.VIII.VII and VI, and lots 7, 8 and 9 of range V .91 of the Education Act.This new school municipality, for elect inn purposes, in accordance with section 54a f the Kdin-at ion Act, will \\>c divided into 4 wards, one for each of the description above mentioned (No.1, 2.3, 4) and représente»! as follows: Ward Xo.1 \u2014 2 members; Ward Xo.2 \u2014 2 mcmljcrs: Ward Xo.3 \u2014 2 members; Ward Xo.4 \u2014 1 member.March 30,1907.Jean-Jacques Bertram'.19150-14-2-o Minister of Education.Sainte-Madeleine Application is made to annex the school municipality of Sainte-Madeleine, in the count y of Outremont, to the school municipality of the city of Outrcmont, in the county of Outretnont.Quebec, April 3, 1907.Jean-Jacques Bertram'.19207-14-2 Minister of Education.Sièges sociaux Head Offices Industrial Import Ltd.Industrial Import Ltd.Avis est, par les présentes, donné que la Notice is hereby given that \"Imlustrial compagnie « Industrial Import Ltd.», constituée Import Ltd.\", incorporated by letters patent on QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1967, Vol.99, No.15 2640 ,i, corporation par lettres patentes le 29ième jour de décembre, 1955, et ayant son siège nocial en la ville de Montréal, à 1255 rue Université, l'a transporté à 1245 ouest, rue Sherbrooke, ,n lis cité et district de Montréal.À compter «le la «late de cet avis, ledit bureau sera eimsidéré par la compagnie comme étant son tiège social.Dalé à Montréal, le 3e jour d'avril 1907.(Sceau) I9240-O Le Président.Arthur Frenkel.13071-55 boa inc.Avis est donné que la compagnie « Loa inc.», a changé son siège social de Charlesl>ourg, au numéro 1290, rue St-Denis, Montréal.Le Président, jacques Boulais.19250-0 778-00 Thetford Cartage Ltd.Avis est donné que la compagnie « Thetford Csrtage Ltd.», a changé son siège social «le Trois-Rivières, au numéro 8535, rue Pascal Gagnon, St-Léonard.Le Secrétaire, Rocer gosselin.19251-0 1847-04 Les Immeubles Donpro Incorporés Avis est par la présente donné que suivant une motion, dûment secondée et acceptée à l'unanimité lors d'une assemblée des actionnaires, que « Les Immeubles Donpro Incorporés », sous la partie I de la Loi des Compagnies de la Province, par lettres patentes datées le 14 février, 1966, a déménagé son siège social de 30 Place Carleton à 39 Place Carleton, Baie Comeau, dsns le district «le Hauterive, dans notre Pro- 19254-4 Le Secrétaire, Gaston Simard, m.d.398-00 W.IL Gilmour Ltd.Avis est donné que la compagnie « W.H.Gilmour Ltd.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies «le Québec, le 27e jour de mars 1902 «\u2022t jusqu'à ce jour ayant son siège social situé à 4,003, boulevard Décarie, l'a transporté à 1210, ouest, rue Sherbrooke, en la ville de Montréal, Québec.A compter «le la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 1er jour de mars 1907.(Sceau) 10274 Le Vice-président, W.N.Gilmour.11139-02 M t.Royal Academy of Language Ltd.Académie Mt-Koyal de Langues ltée Avis est donné que « Mt.Royal Academy of Language Ltd.\u2014 Académie Mt-Royal de Langues ltée », a transporté son siège social de la Jftlle «le Montréal, à 2490, rue St-Louis, St- baurent.Le Secrétaire4réaorier, W.David Anous.19272 5549-04 the 29th day of December, 1955, ami having its head oflice in the city of Montreal, at 1255 University Street, has moved it to 1245 Sherbrooke Street West, in the city ami «listrict of Montreal.From and after this date, the said oflice shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 3r«l «lay of April, 1907.(Seal) Arthur Frank el, President.19249-o 13071-55 Loa inc.Notice is given that \"Loa inc.\", has changed its head office from Charlcsbourg, to number 1290 St-Denis Street, Montreal.Jacques Boulais, President.19250 778-66 Thetford Cartage Ltd.Notice is hereby given that \"Thetfortl Cartage Ltd.\", has transferred its head office from Trois-Rivières, to number 8535 Pascal Street, Gagnon.St-Léonard.Roger Gosselin, Secretary.19251 1847-01 Les Immeubles Donpro Incorporés Notice is hereby given that following a motion, duly seconded and unanimously accepted at a meeting of the shareholders, that \"Les Immeubles Donpro Incorporés\", umler Part I of the Companies Act of the Province, by letters patent dated February 14, 1960, changed its head office 36 Place Carleton to 39 Place Carleton, Baie Comeau, in the district of Hauterive.in Our Province.Gaston Simard, m.d., Secretary.19254 398-00 W.II.Gilmour Ltd.Notice is hereby given that \"W.H.Gilmour Ltd.\", incorporated under Part I of the Quebec Companies Act on the 27th day of March, 1902, and where it's head office was situated up to today at 4,003 Decarie Boulevard, has moved it to 1210 Sherbrooke Street West, in the city of Montreal, Quebec.From ami after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 1st day of March, 1967.(Seal) W.N.Gilmour.Vice-President.19274-0 11139-62 Mt.Royal Academy of Language Ltd.Académie Mt-Royal de Langues ltée Notice is given that \"Mt.Royal Academy of Language Ltd.-Académie M t-Royal de Langues ltée\", has transferred its head office from city of Montreal to 2490 St.Louis Street, St.Laurent.W.David Anc.us, Secretary-Treasurer.19272-o 5549-64 2550 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, tô avril 1907.99' année, n lù B.M.inc.Avis est donné que lu compagnie * D.M.nie.», u changé son siège social de Montréal, au numéro 32s, rue Laurier, Disraeli.Le Secrétaire-trésorier.M.mi: Bona Biavpoin.10873m 4267-66 Imperial Farm Inc.Avis est donné que la compagnie < Imperial Farm Inc.constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies de Quélicc, par lettres datées du 22 août 1960, a son siège social à Sic-Sophie, dans le comté de Terrebonne, province de Québec.Daté à Ste-Sopliie.le 7 mars 1967.Le Seerétaire.\u2022Iran-Paul Francobu».i927ô 3064-66 < oi poiation de placemenIs llillcatb llilleath Investments Corporation Avis est donne que « Corporation de placements 11 illeal h - liilleal h Investments Corporation , constituée en corporation par lettres patente-, émises en vertu «les dispositions de la première partie «le la Loi «les compagnies de Québec en «late «lu 28 mars 1967 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau à 19:50.ouest Dorchester, «lans ladite ville.À compter «le la «late «lu présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, le 10e jour d'avril 1967.(Sceau) Le Président.19277-e Maihkf.Riopblle.Cam-Rose Enterprises Ltd.Avis est donné que la compagnie « Cam-Rose Enterprises Lt«l.» a transporté son siège social «le 4379.avenue Draper, Montréal, à 5501.avenue Alpine.Côte St-Luc.Ix Secrétaire.Ri-tic Cammy.19294 10204-01 U.M.inc.Notice il hereby given that \"IL M.nie.\", has changed its head ollice from Montreal I.338 Laurier Street.Disraeli.Mus.Bona Bbaudoix, Sreretaru-Tn osuw 19973 12574)0 Imperial Farm Inc.Notice is hereby given that \"Impérial farm Inc.\".a company formed under Part I of the Quebec Companies Act.letters patent ixsuedoe August 22.1866b has its hea«l «>(!»\u2022«¦ al Ste.Sophie in the county «>f Terrebonne, Province of Quebec.Dated at Ste.Sophie, on March 7.1967.Iean-Paii.Pbancoei u, Seen tary.19275-0 :;in;'biii; Corporation de placement» llillcalb M il leal b Invest men l - Corporation Notice is hereby given that \"Corporation dc placements llilleath - - Hillcath Investment* Corporation\", incor|)orated by letters patent under Part I of the Quebec Companies Act on the 28th day «>f March 1967 and having its head oflice in the city of Montreal, has established its office at 1930 Dorchester West, in the said city.From ami after the date «>f this notice, the said bolliee shall l>e considère»! by the company u-lieing the head office of the company, (îiven at Montreal, this 10th usidéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté en la vil It* de Moulri:al.ce trentième jour «le mars 1907.Le Secrétaire.I.W.K.Evans.19284-0 3580-00 Société de Placement* K.I.Martin ltée Avis est donné que * Société «le Placements It.I.Martin ltée .constituée en corporation par lettres patentes en vertu «les dispositions de la Loi des compagnies de Québec en date du 11 octobre I960 Cl ayant son bureau principal dans la cité «le Sherbrooke, a établi son bureau au numéro 405 sud, rue Belvédère, «lans ladite «-ilé.À compter «le la «late «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Sherbrooke, f this notice, i|\u201e.said office is considered by the company .;\u2022 heina its head office.Dated in the city of Montreal, this thirtieth day of March, 1967.I.W.K.Bvaxh, (Seal) Secretary.19284 358046 Société de Placements It.I.Martin I lee Notice is hereby given that \"Société de I'la- cements II.L.Martin ltée\", incorporated by letters patent under the provisions of the Qtu-bv Companies Act «tn the eleventh day of Octoler 1990 anil having its head oflice in the eily uf Sherbrooke, has established its oflice at Ilia south.Belvedere street, in the .said city.From and after I he «late «>f this notice the uid office shall be considered by the company u being the head office «>f the company.Dated at Sherbrooke, this 4th day of Januart 1907.Raymond Martin, President.19285-0 1008-08 Examen du Barreau Bar Examination Barreau de Bedford \u2014 Bar of Bedford Candidat vovh l'admission à i.'examen d«- sabbbau Candidate for the admihhion t«» the har examination Xoin Surname Prénom Given name Honin Jean-Pierre Age Résidence Resiflense 24 C201 Hoi-Rene.Ville d'Anjou Granby, M 7 avril 19«7.\u2014 Granby, April 7th 1987, 19287-0 l.c Sicritain du Barreau as Bedford, Jean M uw i-St-eretaru for the liar of Bi dfon Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Village d'Aeton Vale Cadastre officiel du Village d'Aeton Vale municipalité de la ville d'Aeton Vale division d'enregistrement de Bagot.Avis est par la présente donné que les lots 374-3 à 374-11, 590-1, 592-1 à 592-9, 592, 593-1 à 598-8, 593, 594, 595-1 et partie des lots 374, 585-1.585, 580-1, 580, 587-1, 587, 589-1, 589, 590, 595 sont annulés et les lots 009 et 070 sont ajoutés en vertu de l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 22 mars 1907.Le Sous-ministre, 19244-o Fehnand Boutin.Paroisse de Lachinc ( 'adastre officiel de la paroisse de Lachine, municipalité de la cité de Lasalle, division d'enregistrement de Montréal.Village of Acton Vale Official Cadastre of Village of Acton Vale, municipality of the town «>f Acton Vale, registre* tion division of Bagot.Notice is hereby given that lots 374-3 lo 11, 590-1, 592-1, to 592-9, 592, 593-1 to 593* 593, 594, 595-1 and part of lots 374, 585-1 583.580-1, 58G, 587-1, 587, 589-1.589, 590, 595 are cancelled and lots 009 ami 070 arc added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec March 22, 1907.F WIN AN 1) BOUTIS.19244-o Deputy Minister.Parish of Lachine Official cadastre of the parish of Lachine, municipality of the city of Lasalle, registration division of Montreal. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 16, 1967, V», 99, Xo.to Avis est pur la présente donné que le lot 1073 (>t ajouté en vertu «le 1'artiele 2174A «lu Code civil.Québec.I«' 30 mars 10(57.Le Sous-ministre, lu FekNANI) BoUTIN.Paroisse de Lacbiue Cadastre officiel «le la paroisse de Lachine, municipalité «le la cité «le Lasalle.division d'enregistrement de Montréal.A\\i- est par la présente donné que le lot 1071 es| ajouté en vertu «le l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 30 mars 1907.Le Sous-ministre, 19211 -' > Fern an n BoUTIN.('.union de La Sarre (partie) ( 'adastre officiel «le partie «lu Canton de La Sarre.municipalité «lu Canton «le La Sarre, division d'enregistrement d'Ahitibi.Avis eSt par la présente donné que les lots lit»-1 à 29-8 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 13 mars 1907.Le Sous-ministre, 19244-0 Feknand Boutin.Paroisse de St-Hilaire Cadastre olliciel «le la paroisse de St-Hilaire, municipalité «le ville «le Mont-Saint-Hilairc, division d'enregistrement «le Rouville.Avis eSl par la présente donné que le lot 93-14 esl annulé en vertu de l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 30 mars 1907.Le Sous-ministre, 19244m Fern and Boutin.Cité de Montréal, Quartier St-Antoinc Cadastre officiel «le la cité «le Montréal, quartier St-Antoine, municipalité de la ville de Mont-réal, division «l'enregistrement «le Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 1121.1421-1, 1421-2 et une partie des lots 1422, 1422-1, 1422-2 et 1422-3 sont annulés et le lot 1948 est ajouté en vertu de l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 30 mars 1907.Le Sous-ministre, 1 \"211 -< > Fern an n Boutin .Paroisse de Ste-Marguerite Cadastre officiel «le la paroisse «le Ste-Marguerite, municipalité de la paroisse de Stc-¦Mar.uucrite du Lac-Masson, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente «lonné que les lots 23-1-14, 23-1-18 à 23-1-22, 23-1-27, 23-1-28, -M-l-ii.24-1-8 à 24-1-14 du rang VI, canton Wexford, sont annulés en vertu de l'article 2174A Code civil.Québec, le 30 mars 1907.Le Sous-ministre, 19244-0 Fern and Boutin.Paroisse de Ste-Rose ( adastre officiel de la paroisse de Ste-Rose, municipalité de la ville de Laval, division d(uregistrement de Laval.2553 Notice is hereby given thai the lot 1073 is added in virtue of Article 2174A of the Civil co«le.Quebec, March 30, 1907.Fern an n Boutin.19244-o Deputy Minister.Parish of Lachine Official cadastre of the parish of Lachine, municipality of the city of Lasalle.registration «li-vision of Montreal.Notice is hereby given that the lot 1074 is added in virtue of Article 2I74A of the Civil «\u2022ode.Quebec, March 30, 1907.Fern an i> Boutin .I0244-o Deputy Minister.Township of La Sarre (Part) Official cadastre of part of the township of La Salle, municipality of the township of La Sarre, registration division of Abitibi.Notice is hereby given that lots 29-1 to 29-8 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil code.Quebec, March 13.1907.Fern an d Boutin.19244-o Deputy Minister.Parish of St-Hi lain Official cadastre of the parish of St-Hilaire.municipality of the town of Mont-Saint-Hilairc.registration division of Rouville.Notice is hereby given that lot 93-14 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil code.Quebec, March 39.1907.Fern an n Boutin, 19244-o Deputy Minister.City of Montreal, St.Antoine Ward Official cadastre of the city of Montreal, St-Antoine Ward municipality of the town of Montreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 1421, 1421-1.1422-2 and one part of lots 1422.1422-1, 1422-2 and 1422-3 are cancelled and the lot 1948 is added in virtue of Article 2174A of the Civil code.Quebec, March 30.1907.Fern an i> Boutin.19244-0 Deputy M in ister.Parish of Stc-Marguerite Official cadastre of the parish of Stc-Marguerite.municipality of the parish of Ste-Marguerite «lu Lac-Masson, registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lots 23-1-14.23-1-18 to 23-1-22.23-1-27, 23-1-28.24-1-0, 24-1-8 to 24-1-14 range VI, township of Wexford are cancelle«l in virtue of Article 2174A of the Civil code.Quebec, March 30, 1907.Fern an » Boutin, 19244-o Deputy M in ister.Parish of Ste-Rose Official cadastre of the parish of Ste-Rose.municipality of the town of Laval, registration di-vision of Laval. 2554 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, tâ anil 1907, 99' année, n\" I.', Avis est par la présente donné que le lot 49-230 Btt annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Queuec, le 28 mars 1907.Le Suus-iiLJit istre, 19244-0 Perm and Boutin.Paroisse de Bcatiport Cadastre officiel de la paroises tie Bcauport, municipalité «le la ville «le Villeneuve, «livision d'enregistrement «le Québec.Avis est par la 'présente donné que le lot 328-9 est annulé eu vertu de l'article 2I74A du Code civil.Ottébee, le 30 mars 1907.Le Sous-ministre.19244«o Fern and Boutin.Paroisse de St-Hilairc < adastre olliciel «le la paroisse de St-Hilaire.municipalité «le Ottcrburn Park, «livision «l'enregistrement «le Rouvillc.Avis est par la présente donné «juc les lots 137-72-2.137-73-2.- 137-74 à 137-70.137-79 à 137-94, 13S-111 à 13S-114, 138-110 à 138-122, 138-124, 138-126, 138-128, 138-180 à 138-151, 138-154 à 138-157, 138-159 à 138-180, 139-1G5 à 139-170.139-182 à 139-213, 139-238 à 139-240, 139-270 à 139-274, 143-351 à 143-355, 143-375, 143-870, 143-395, 143-390, 143-404 à 143-478, 143-484 à 143-495, 143-503 à 143-514.143-519 et 143-520.143486 à 143-529.143-534 à 143-539.143-545 à 143-548, 143-553 à 143-550, 143-505 à 143-570.143-578 à 143-581, 143-586 à 143-594, 143-590 à 143-598, 144-378, 144-379, 144-420 à 144-422, 144-425 à 144-427, 144-440 à 144-452.144-400 à 144-472, 144-489 à 144-493, 144-498 à 144-505, 144-510 à 144-515, 144-517, 144-518, 144-522 à 144-530.144-534 à 144-537.144-541 à 144-549, 144-553, 144-554, 144-550 à 144-502, 144-508 à 144-571.144-575 à 144-579, 144-585 à 144-590.144-599 à 144-013, 144-015 à 144-019, 144-029 à 144-031.144-033 à 144-045, 144-052 à 144-057, 144-081 à 144-084 et une partie des lots 137-72 et 137-73 soat annulés en vertu «le l'article 2174A «lu Code civil.Québec, le 15 mars 1907.19244-0 Le Sous-ministre, Fern and Boutin.Notice is hereby given that lot 49-230 i-cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil code.QlltbfjC, March 28, 1907.Fkhnand Boutin*, 19244-o Deputy M in iiU r Pariah of Beaiiport Official cadastre of the parish of Beauport, municipality of the town of Villeneuve, regis, trution division of Quebec.Notice is hereby given that the 1«>1 328-9 i-canccllcd in virtue of Article 2174A «»f the Civil code, Quebec, March 30, 1907.Feunand Boutin, 19244-0 Deputy Minier Parish of St-Hilaire Official cadastre of the parish «>f St-Hilaire, municipality of Ottcrburn Park registration division of Rouvillc.Notice is hereby given that lots 137-72-2, 137-73-2, 137-74 to 137-70, 137-79 to 137-94 138-111 to 138-114.138-110 to 138-122, lift 124, 138-120, 138-128, 138-130 to 138-151, 138-154 to 138-157, 138-159 to 138-180.139-105 to 139-170.139-182 to 139-213, 139-238 to 139-240, 139-270 to 139-274, 143-351 to 143-355, 143-«75, 143-370, 143-395, 143-390, 143-401 to 11.'!-478, 143-484 to 143-495, 143-503 t«> 143-514, 143-519 and 143-520, 143-520 to 143-529, 143-534, to 143-539, 143-545 to 143-548.143-553 la 143-556, 143-505 to 143-570, 143-578 to 143-581, 143-580 to 143-594, 143-590 t«> 113-598, 144-378, 144-379, 144-420 to 144-422.144-425 to 144-427.144-440 to 144-452, 144-4641 to 144-472, 144-489 to 144-493, 144-498 t.144-505, 144-510 to 144-515, 144-517.144-518, 111-522 to 144-530, 144-534 to 144-537, 144-541 t 144-549, 144-553, 144-554, 144456 to 144-562, 144-508 to 144-571, 144-575 to 144-579, III-685 to 144-590, 144-599 to 144-013, 144-615 to 144-019, 144-029 to 144-031, 144-033 to 144-045, 144-052 to 144-057, 144-081 to 144-681 and one part of lots 137-72 and 137-73 are can-celled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, March 15, 1907.Fern and Boutin.19244-u Deputy Minister.Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation 1 Department of Agriculture and Colonization Coopérative régionale des producteurs de patates de I.otbinibrr Avis est donné «pie.lors «l'une assemblée générale spéciale «les membres de la * Coopérative régionale «les producteurs de patates de Lotbinière tenue à Lothiuièrc le 20 «lécembre I900, il a été résolu à l'unanimité de liquider la coopérative, conformément aux dispositions de l'article 33 «le la Loi «les sociétés coopératives agricoles.Statuts refondus, 1004, chapitre 124, «\u2022t «pie M.Florent Orolcau a été nommé liquidateur.Donné au bureau «lu ministre «le l'Agriculture cl «le la Colonisation ce troisième jour «l'avril 1907.Le Sous-ni in istre de l'Agriculture et de la Colonisation, 19243-0 Romeo Lai.an de.Coopérative régionale des producteur-de patates de Lotbinière Notice is hereby given thai at a special general meeting of the memliers of \"Coopérative régionale «les producteurs «le patates «le Lotbinière \u2022 held at Lotbinière on I)cccml>cr 20.1900, :> resolution was adopted unanimously to wind up the cooperative, in conformity with the provisioni of section 33 «>f the Cooperative Agricultural Associations Act, Revised Statutes, 1964, chapter 124, and that Mr.Florent (îroleau was appointed liquidator.Given at the office of the Minister «>f Agriculture and Colonization this third f registry number 1388.authorizing it.as from the 0th of March 1907.to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Fire, and supplementary thereto civil commotion, earthquake, falling aircraft, hail, impact by véhicules, sprinkler leakage, water damage, weather, wimlstorm; Accident; Automobile; Boiler (excluding machinery); Explosion; Inland transportation; Personal property; Plate glass: Ileal property; Theft.The head office of the company is situated at 259, Genesee Street.Utica, New York.United States of America.The company has appointed the Honourable Senator Jacques Flynn, P.C., ec, le 11 avril 1967.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19310-n 148-66 de Cadre de Verdun (CSN)\", has been autho* rized bv the Provincial Secretary on Much 7 1967.The head ollice of the said professional lyndj.cate is situated at 1001 St-Denis St., judicial district of Montreal.Quebec March 9, 1967.Raymond Doumi.i i.Assistant Secretary of the Province, 19255 I-ii; Association des Principaux du Diocèse de Trois-Rivières (Professional Syndicates Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association «les Principaux «lu Diocèse de Trois-Rivières\", has been authorized by the Provincial Secretary OH March 17.1967.The head office of the said professional syndicate is situated at Trois-Rivières, judicial districl of Trois-Rivières.Québec, April 6, 1967.Raymond Dodville, Assistant Secretary of the Province.1925s 36*63 Association Profession nolle des Pharmaciens Salariés du Quebec (Professional Syndicates' Act) The incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association Professionnelle «les Pharmaciens Salaries du Québec\", has been authorized bv the Provincial Secretary on April 11, 1967.The head office of the said professional syndicate is situated at Montréal, judicial «listrict of Montreal.Québec.April 11, 1967.Raymond Douvii.i.i.Assistant Secretary of the Provinei 19310 148-66 Liquidation \u2014 Avis de Coopérative Téléphonique de Lemieux Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des membres du syndicat «coopératif « Coopérative Téléphonique de Lemieux », tenue à Lemieux, le 28 décembre 1966, il a été résolu que les affaires de ladite société soient liquidées, et que celles-ci soit dissoute, et ce, en vertu des dispositions de la Loi des syndicats coopératifs de Québec et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Henri Deshais, Euclide Manchette et Lucien Beaulieu ont été nommés liquidateurs.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.I9240-o 1713-53 G.B.Talent, inc.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « G.B.Talent, inc.», tenue à Montréal le 31 décembre 1966, il a été résolu «juc les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, et ce, en vertu «le la Loi de la liquidation des compagnies et que Maheux, Noël & Cic a été nommée liquidatrice.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.10280m 4284-40 Winding up Notices Coopérative Téléphonique de Lemieux Notice is given that at a special general meeting of the members of the cooperative syndicate \"Coopérative Téléphonique de Le-mieux\", held at Lemieux, on Deceml>er 28, 1966, it has been resolved that the affaires of the said association be liquidated, and that these Ix* dissolved, and such, in virtue of the provisions of the Cooperative Syndicates Act of Quebec and of the Winding-Up Act, and that Messrs.Henri Deshais, Euclide Blanchette ami Lucien Beaulieu have been appointed liquidators.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.19240 1713-53 G.B.Talent, inc.Notice is given that, at a special general meeting of the shareholders of \"(1.B.Talent, inc.\", held in Montreal on December 31.1906, it has been resolved that the affairs of the said company l>e liquidated, and that the latter be dissolved, and such, in virtue of the Wiiulin^'-l p Act and that Maheux, Noël & Cie has been appointed liquidator.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.19286 4284-40 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 15, 1967, Vo.99, No.15 2559 Bcaillicu Incorporated Avi- est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « Meaiilicu Incorporated », tenue ù Québec le là mars 1907, il u été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées et que celle-ci -oit dissoute en vertu de l'article 9 «le la Loi «le la liquidation «les compagnies et que M.1.II.Monoglian, a été nommé liquidateur.Le Sous-secrétaire de la province, RAYMOND Douvillk.I'.cjii-o 1672-35 Beaulicu Incorporated Notice is hereby given that at a special general meeting of the shareholders of \"Beaulieu In-corporate«l\", held at Quebec, March 15, 1997, a resolution was passed to the effect that the business of the said company be wound up and that it be dissolved in pursuance to section 9 of the Winding Up Act, and that Mr.J.II.M«>-naghan, was appointed liquidator.RAYMOND Douvillk, Assistant Secretary of the Province.19311 1072-35 Nominations Appointments Avi- est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil «le faire, par commission -on- le grand sceau, la nomination suivante: Québec, le 10 mars 1907.M.Claude Duguay.nié«leein, de Grande-Rivière, coroner conjoint pour le district jmliciaire \u2022 !«\u2022 (Jaspé, avec juridiction seulement sur celle partie «lu «listrict électoral «le Gaspé-Sud, comprise entre la Rivière St-Jean et les limtes nord-est du «listrict électoral «le Bonaventure.à compter de la «late de son assermentation.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Douvillk.19228-0 13-07 Avi- est donné Qtt'il a plu au lieutcnant-gouverneur en conseil «le faire, par commissions m.u- le grand sceau «le la province, la nomination suivante: Québec le 18 janvier 1907.M.Camille Miehaud, médecin, «le Saint-Paulin, coroner conjoint pour les district jmliciaire- de Trois-Rivières, «le Saint-Maurice et «le Joliette, avec juridiction seulement sur le district électoral de Maskinongé, à compter «le la «late «le son a-erinentation.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.l'.e.'s.,, 2-07 avis est donné «|u'il a plu au lieutcnanl-gouverneur en conseil de faire, par commissions sous le grand sceau, la nomination suivante: Québec, le 8 mars 1967.M.Ludovic Laperrière.avocat, membre du Barreau de la province et conseil en loi de la Reine, de Trois-Rivières: nommé en vertu de I article 117 «le la Loi «les tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), juge «le la ( our provinciale, avec juridiction dans toute la province, mais tout particulièrement et sans restriction, «lans le district judiciaire de Québec, selon l'article 126 des Statuts refondus de Québec, 1964, chapitre 20, comme juge de district en ce (|in concerne les juridictions attribuées par les lois du Parlement «lu Canada aux juges «le district, que ces juridictions leur soient attribuées sous le titre «le « magistrat» ou sous celui de \"juge de «listrict», avec résidence dans la ville de Québec ou dans les environs, ledit M.Ludovic Laperrière, vu sa présente nomination par le lieutenant -gouverneur en conseil comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, Mus l'autorité «lu paragraphe b) de l'article 400 ,hl ( «de criminel, à compter du 8 mars 1967.Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make, by commission umler the firent Seal, the following appointment: Quebec, .March 10.1907.Mr.Claude Duguay.doctor of Grande-Rivière, joint coroner for the judicial district of (îaspé.with jurisdiction only on this part of the electoral «listrict of Gaspé-South, included between Si-Jean River ami the north-cast limits of the electoral «listrict of Bonaventure.from and after the «late of his swearing in.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.1922S 13-07 Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make, by Commission under the Great Seal of the the following appointment: Quebec, January bs, 1907.Mr.Camille Miehaud.doctor of Saint-Paulin, joint coroner for the judicial districts of Trois-Rivières, Saint-Maurice and Joliette, with jurisdiction only in the electoral «listrict of Maskinongé.from and after the «late of his swearing in.Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.1922N 2-07 Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council, by commission under the Great Seal, has been pleased to make the following appointment : Quebec, March S, 1907.Mr.Lutlovic Laperrière.advocate, mcml)cr of the Provincial Bar and Queen's Counsel, of Trois-Rivières: appointed umler section 117 of the Courts of Justice Act (Revised .Statutes, 1904, chapter 20), Provincial Court Judge, with jurisdiction in the entire Province, but especially and without restriction, in the judicial district of Queliec, according to section 120 of the Revised Statutes of Quebec, 1904, chapter 20, as «listrict jmlgc in that which concerns jurisdictions attributed by the laws of the Canadian Parliament to district judges, whether these jurisdictions be granted to them umler the title of \"magistrale\" or under that of \"«listrict judge\", with residence in the City of Quebec, «>r in the vicinity; the said Mr.Ludovic Laperrière, in view of his present appointment by the Lieutenant-Governor in Council as Provincial Court Judge, is authorized to exercise, under the authority of paragraph (/>) of section 400 of I he Criminal Co avril 1907.99' année, n\" lô la juridiction d'un magistral lOUI la partie XVI (!«\u2022 «¦«\u2022 ('«nie criminel.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.I922s.«, 12-07 Avis est donné «pi'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil «le faire, par commissions sous le grand sceau, les nominations suivantes: Qtlébec, le 1S janvier 1907.M.1.-Octave La tour, notaire, «le Saint-Kusta-che, régistrateur «le la «livision «l'enregistrement «le Deux-Montagnes, à Saint-Scolustique.à compter «l«* la «late «le son assermentation.5-07 M.Gérard Lavallée, médecin, de Lavaltrie, coroner conjoint pour les districts judiciaires «le Joliette et «le Trois-Rivières, avec juridiction l'étendant plus particulièrement sur cette partie du «listrict électoral de Herthier qui comprend les paroisses de Lavaltrie, Lanoraie, Berthier, Saint-Iguace-«le-L«>yola, l'Ile Dupas, Saint-Via-teur et Saint-Barthélémy, à compter de la date de son assermentation.3-07 M.J.-L.Lefebvre, médecin, «le Saiut-Gahricl-dc-Brandon.coroner conjoint pour les «listricts judiciaires «le Joliette et «le Tn)is-Rivièrcs, avec juridiction s'étendant plus particulièrement sur cette partie «lu «listrict électorale «le Berthier qui comprend les paroisses «le Saint-Michel-des Saints, Saint-Zenon, Sant-Damicn, Saint-Ga-briel-de-Bran«lon, Saint-Charles- that u hieli Saints, id-de-Saint- ter the 34B Mr.J.-L.Lefebvre, physician, of Sai briel-de-Braudon, joint coroner for the j «listricts «»f Joliette and Trois-Rivières, jurisdiction extending more especially h part of the electoral «listrict of Berthier includes the parishes of Saint-Michel-dc> Saint-Zenon, Saint-Damicn, Saint-Gabi Brandon, Saint-CharIes- De plus, «les soumissions pourront être envoyées cl elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance dix ans \u2022mi à courte échéance quinze ans.Cependant, les soumissions ne «levront comporter qu'un seul 'les trois termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligation s, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.be capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province tie Québec, de la banque dont le nom est mentionné dans la procé-dure d'emprunt.besides obligations ne seront pas rachetai îles par anticipation.' liaque soumission devra être accompagnée dun chèque accepté égal à 1% du montant de 'emprunt et «levra spécifier si le prix offert comprend pas les intérêts courus sur les obliga-hons au moment «le leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées a une séance «les commissaires d'écoles qui sera «nue lundi, le 1er mai 1907.à 7 heures 30 du soir, Ecole Champagnat, 233, blvd Pierrc-Ber-lr«nd.ville Vanier, comté de St-Sauveur, P.Q.bes commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Table of redemption $450,000 86 years Year Capital May 1, 1968.x $38,500 May 1, 1969.x 41,000 May 1, 1970.x 44,000 May 1, 1971.x 47,000 May 1, 1972.x 50,500 May 1, 1973.x 54,000 May 1,1974.7,500 Mav 1, 1975.8,000 May 1, 1976 .9,000 May 1, 1977.9,500 May 1,1978.10,000 Mav 1, 1979.11,000 May 1, 1980.11,500 May 1,1981.12,500 May 1, 1982.13,500 May 1, 1983.14,500 May 1,1984.15,500 May 1, 1985.16,500 May 1, 1986.17.5(H) May 1, 1987.18,500 The letters \"x\" indicate the years during which annual payments of a total amount of $300,000 grantc«l by the Provincial Government and payable in 6 instalments of $50,000 each, from 1968 to 1973 inclusively, will be received ami applied to the service of the said loan.Moreover, tenders may l>c forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shall be considered for one of the three terms only.Adjudication shall l>e made according to law.The successful temlerer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Quebec.Capital and interest are payable at all the branches in the Province of Quebec, of the bank whose name is mentioned in the loan procedure.The said bonds will not l>e redeemable by anticipation.Each tender must be accompanie«l by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue ami must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, May 1, 1967, at 7:30 o'clock p.m., at Champagnat School, 233 Pierre-Bertrand, ville Vanier, county of St-Sauveur, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any «>f the tenders. 2562 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, lô avril 1967, 99' année, u0 16 Ville Vanier, (Comté de St-Sauveur), ce I avril 1%7 Le Secrétaire-trésorier, J.-Rosaikk Flamand.Keole Champagnat, 233, blvd l'ierrc-Bertraml, ville Vanier, (St-Sauveur), P.Q, Téléphone: 683-7317, code -IIS.H)242-o Ville Vanier, (Countv of St-Sauvem .\\i\u201ej| 4, 1967.I.-Hosaiuk Flam \\s », Sécréta ry-Tn murer.Champagnat School, 233 Pierre-Bertrand Blvd.ville Vanier, (St-Sauveur), P.Q.Telephone : 683-7317, code 418.19242 Cité de Hull Comté de Hull Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions |K)ur obligations » seront reçues par le soussigné Roland Stevens, greflier, Hôtel de Ville, Hull, comté «le Hull, P.Q., jusqu'à 3 heures «le l'après-midi, mardi, le 2 mai 1967, pour l'achat de 11,176,000 «l'obligations «le la cité «le Hull, comté «le Hull, «lat«''cs «lu 1er mai 1967 et remboursables par séries du 1er mai 1968 au 1er mai 1987 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 6r,, m supérieur à 7r[, payable semi-annuellement les 1er mai et 1er novembre de chaque MUlée, divisé «le la manière suivante: Série « A » au montant de 8337,000 d'obligations, rachctables par anticipation échéant comme suit: 1er mai 190S.§26,000 1er mai 1969.27,000 1er mai 1970.29,000 1er mai 1971.30,000 1er mai 1972 .32,000 1er mai 1973 .34,000 1er mai 1974 .36,000 1er mai 1975 .39,000 1er mai 1976.41,000 1er mai 1977.43,000 City of Hull 4,500 of bonds for the town of Tracy, county of Richelieu, dateil May 1.1967, and redeemable serially from May I, I'.His to May 1, 1987 inclusively, with interest at a rate not less than 6%, nor more than 7','.payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to maturities.By-laws Nos.: 198 \u2014 $37,000 \u2014 aqueduct sewers, roads; 199 - - $200,000 - - recreational and community services; 201 - - $35.0(10 \u2014 aqueduct, sewe'rs, roads: 210 \u2014 $182,000 aqueduct, sewers, roads; 211 \u2014 $110.000 works at the Town Hall.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1907.Table of redemption - $564,500 - $0 yean Year Capital May 1, 1968 .8 11.500 May 1,1969.12,500 May 1,1970.13.000 Mav 1, 1971.14.000 May 1,1972.15.000 May 1,1973.16,51 Mi May 1,1974.17,000 May 1,1975.18,500 May 1, 1976.19.000 May 1,1977.20,500 May 1,1978.22,000 May 1,1979.24,000 May 1, 1980.25,000 May 1,1981.26,500 May 1,1982.28,50\" May 1,1983.31.000 May 1,1984 .32,600 May 1,1985 .34,500 May 1,1986 .37,500 May 1,1987.145.5IMI Moreover, tenders may be forwarded and shall be considered as ten-year short-term and fifteen-year short-term bonds.However, tenders shwl be considered for one of the three terms only-Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Tracy.Capital and interest are payable at all branche» in the Province of Quebec of the bank mentioned QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 15.1907, Vol.99, No.15 2587 banque c opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Thursday, May 4.1967, at 7:00 o'clock, p.m.at the office «>f the school commission, 554 Limoges Street, St-Jovite, county of Terrebonne, P.O.The school commissioners «!«> not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Jovite, (County f Bedford, defendant, and CEO.ST.JACQUES, «if Mansonville.district of Bedford, mis-en-cause.\"Lots 359 and 300 on the official plan of the cadaster for the township of Stukely.containing about 100 acres of land of which .lack Calvin is the joint proprietor with Beulali Calvin, the plaint iff.Lots 3 and 1 in the township of Stukely, containing aixuit 00 acres of land, being part of the «)l«l C.P.R.railroad.To l»e sold at the registry office of Waterloo, countv of Shefford, Que., district of Bedford, on the SEVENTEENTH .lay of MAV, 1907.at THREE o'clock in the afternoon.Sheriffs oflice, Antonio Bolhassa.( 'ourt House.Deputy-Sheriff, ( owansville.P.Q., March 28, 1907.19297 ( 'anada - - Province of Quebec District of Bedford Provincial Court, ( A LDEN TICEHURST, No.M-26.\\ auctioneer, domiciled \\ on Montreal Road, district of St.Francis, plaintiff, r.v ÉGIDE BOUCHARD, residing in the municipality of South Stukely.«listrict of Bedford, defendant.1.Lot number one hundred and ninety-nine (No.199) in the official cadaster of the township of Stukely, having an area of one hundred ami forty-five acres, more or less; save, however, and to be withdrawn from the said lot: (a) That part of said lot measuring thirty feet by eight ro«ls near the cemetery, ami as presently surrounded by a fence.(6) That part already sold by Berccus Beauregard, now belonging to Joseph Karsa or representatives, and designated as follows: \"An emplacement, with the buildings thereon erected, lying ami situated on the south-west side of Provincial Highway No.1 (Montreal-Shcrbrookc), measuring two hundred feet in width along the said highway ami at the other end, by a depth of three hundred and thirty feet (200' x 330'), known an«l designated on the official plan ami in the hook of reference for the said township of Stukely as being a part of hit number one hundred ami ninety-nine (P.199).and more fully dcscribctl as follows: starting at a point on the north-cast side of said Highway No.1, which point is in a line with the southeast wall of the house on \"the farm which is presently sold; and, from this point, going towards the south-cast lying along saitl highway No.1, a distance of two hundred and thirty-five 2572 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'fill EC, là avril 1907, 99' année, n M étant le point «le départ, et «le ce point de départ touillant à angle «Iroit «-t allant yen K' nor«l-est jusqu'à un point situé à une «listaïu'e «le trois «\u2022«¦ut trente-pieds (330') «le ladite route No l.«!«' là, tournant à angle «Iroit et allant vers le sud-est, parallèlement avec ladite route No 1, une distance «le «l«-ux cents pieds (200') delà, tournant à angle droit et allant vers le sud-ouest jusqu'à ladite route No l.une distance «le trois cent trente pieds (330/); enfin de là.allant jusqu'au puinl de départ eu longeant ladite route No I.une distance de deux «-ents pieds (200').\"_\\ Le coin sud-est «lu lot numéro cent soixante -dix-lmit (1*.S.-K.No 178) borné au nord et à l'ouest par un chemin public, à l'est par la ligne lie division entre les lots cent soixante-dix-huit (I7S) et cent «piatre-vingt-dix-neuf (190) et au sud par le «dieinin de Magog.Cette partie ayant une superficie approximative «le «leux aères et: \u2022b l'n morceau «le terre à prendre «lans le in sud-ouest du lot numéro «leux cent (200) «le la contenance de trois aères «le terre en superficie plus ou moins, et se trouvant située entre un ruisseau et une autre partie «lu même l«)t appartenant à Oscar M.George «m repré'sen-taiits; ledit terrain mesurant «juatre-vingts pic«ls plus ou moins sur la route Montréal-Sherbrooke et s'étendant vers h» nord jusqu'à un point sur h- ruisseau susdit.Avec maison et toutes autres bâtisses y érigiées.Pour être vendu au bureau «l'enregistrement.île Waterloo, comté «le Sheflford, le VINGT-QUATRIEME jour de MAI 1907, à TROIS heures de l'après-midi.Le Député-Sliérif, Bureau «lu Shérif.Antonio Roi/kassa.Ce 28 man 1967.l9315-o feet (235') to another point known as being tin-starting point; and, from this starting point, turning at a right angle and going toward-, the north-east as far as a point situated at a distance of three hundred ami thirty feet (330) from said Route No.1; thence, turning at a right angle and g«>ing towards the south-east.parallel to said Route No.1, a distance of two hundred feet (200'); thence, turning at a right angle and going towards the south-west as far a- aaid Route No, I.a distance «»f three hundred and thirty feet (330'); finally, going to the sin tiny point, along said Route No.l.a distance ol two hundred feet (200').2.The south-east corner «>f lot number one hundred and seventy-eight (P.S.-K.178), bounded on tht* north and on the west by a public roa«l.on the east by the «livision line between lots one hundred and seventy-eight (178) and one hundred and ninety-nine (199), and on the south by the Magog road.Tin- part lias an approximate area of two acres, and: 3.A piece of land to be taken from the southwest corner of lot number two hundred (200) having an area «>f three acres «>f laud more or less, and situated between a brook and another part of the same lot belonging to Oscar If.George or representatives; the said terrain measures eighty feet more or less on the Montreal-Sherbrooke highway, ami extends t«» the north as far as a point on the aforementioiu'd brook.With the house and other buildings thereon erected.To be sold in the registrv office in Waterloo, county of Shefford, on the TWENTY-FOURTH day of MAV.1907.at THESE o'clock in the afternoon.Antonio BoUBASSA, Sheriff's Office, Deputy-Sheriff.March 28, 1967.19315 HULL Canada \u2014 Province «le Québec District de Hull Cour Supérieure, C OEORGES CYR, ès-qua- No 900).\\ lité «le tuteur à son fils l mineur André Cyr, domicilié «\u2022n les cité et «listrict «le Hull, au numéro 12.rue May, demandeur, m GASTON DOMPIERRE, électricien, «les cité et district «le Hull.153 rue Font aine, défendeur.« Un emplacement connu et «lé'signé comme étant le lot numéro trente «le la subdivision officielle «lu lot originaire «leux cent quarante-quatre, quartier un.Cité «le Hull; (244-30 Q.1).Avec bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.» Pour être veiulu à mon bureau, au Palais «le Justice, en la Cité «le Hull, le SEIZIÈME jour d«> MAI.1907.à TROIS heures «le l'après-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif.R.St-Pierre.Ce 10 avril 1907.19298-o ( 'anuda \u2014 Province «le Québec District de Hull Cour Supérieure, ( ALPHONSE PRUD -No 6718.j \" HOMME, cultivateur ' «le Kassett, «listrict de Hull, demandeur, m PHILIPPE (LOITIER, de Fassett, «lit district, défendeur.HULL Canada - Province of Quebec District of Hull Superior Court, i fJEORGES CYR, in lus en» No.9010.j ^ pacity of tutor to his ' minor son André Cyr.domicile»! in the city and district of Hull, at number 12, May Street, plaintiff, at GASTON DOMPIERRE, electrician, of the city ami «listrict of Hull, 153 Fontaine Street, .4891.j 1 CREDIT BUREAU, ' body politic and corporate, having its bead office at Quebec, plaintiff, r* EMILE FORTIER.farmer, formerly domiciled at St-Pierre Baptiste, county of Mégantic now at Ste-Anastasie, defendant.\"1.A piece of land situated on the «deventh range in the parish of St-Pierre-Baptiste.county of Mégantic, containing forty acres iu area, more «>r less, known on the official cadastre of the parish of Ste-Sophie.township of Halifax, as being a part of lot number seven hundred and sixty (Pt.No.700) measuring two arpents in width on the depth existing from the line between ranges ten ami eleven to the public roa«l cutting this lot.bounded in front on the northeast by the public road cutting the lot, in the back on the southwest by the line between ranges ten and eleven, on one side on the southeast by a part of the same lot, belonging to Alcide Poirier, or his representative, and on the other side «>n the northwest by lot number seven hundred and sixty-one.Subject to the servitude in favor of The Shawinigan Water and Power Company according to the deed referring to it.2.Another piece of lain! situated on the same range of the same parish, containing sixty acres in area, more or less, known on the ollicial cadastre of the parish of Ste-Sophie, township of Halifax, as being the northeast part of lot numbers seven hundred ami fifty-nine ami seven hundred and sixty (Pt.N.E.Nos.759 ami 700), bounded on one end on the northeast by tlu-public roa«l between the townships of Inverness and Halifax, on the other end on the southwest by the public road cutting these lots, on one side on the southeast by Jot seven hundred and fifty-eight and on the other side on the northwest by lot seven hundred and sixty-one.Subject to the servitude in favor of The Shauimgaii Water ami Power Company according l«i the «leed referring to it.3.A piece of land situated «»n the eleventh range of the township of Halifax, county of Mégantic.containing one hundred and twcnty-tw«> acres iu area, more or /ess.known on the official cadastre of the parish of Ste-Sophie.township of Halifax, as being lot numbers seven hundred 2574 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, U anil 1007, 99' année, n\" tû soixante-neuf (Nos 768 et 788) avec toutes les l>Atisses dessus érigées, circonstances et dépendances.Sauf et à distraire tin lot numéro sept cent soixante-neuf, une petite partie appartenant maintenant à Alphée Ouellctte, telle qu'elle est.décrite dans un contrat de vente enregistré sous le numéro 44488.4° t'ne propriété située sur le dixième rang de la paroisse de St-Picrrc-Baptiste.comté de Mégantic.mesurant cinq arpents de largeur sur huit ar|K'iits de profondeur, connue au cadastre olliciel de la paroisse «le Ste-Sophie, canton d'Halifax, comme étant la partie nor«l-est «lu lot.numéro sept «-eut n the «-enter part of the same lot f the parish of St-Pierre-Baptiste, county of Me-trant ic, containing one hundred acres in area, more or less, known on the official cadastre of the township of Inverness, as being lot number one hundred and twelve (No.112) with buildings erected thereon, circumstances and dependencies.\" To !>c sold \"en bloc\" at the registration oflice of the county of Mégantic.Inverness di\\ ision, at Inverness, countv of Mégantic, TUESDAY.ll»-THIRTIETH day of MAY, 1907, at TES o'clock in the morning.Denis Gubnki n.19300 Shérif MONTRÉ A L Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: i \\ÂO U L DIN G P R O -No 719 871. ED, demanderesse, ai SHANE HOMES LTD., défenderesse et S.B.FREED, défendeur, ès-qualité.« Subdivision 279 du lot originaire No 95 (95-279) aux plan et livre «le renvoi officiels «le la paroisse de Montréal ».« Subdivision 280 du lot originuirc No 95 (95-280) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal lesquels sont situés en la cité de Côte Saint-Luc, district de Montréal.» Pour être vendues à mon bureau, en la cité «le Montréal, le DIX-HUITIÈME jour du mois «le MAI 1907, à ONZE heures «le l'avant-midi.Le Shérif, Bureau «lu Shérif, Bernard Sarrazin, en.Montréal, 10 avril 1007.19301 MONTRÉA L Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, to wit: (\\JOULDINO PRO-No.719871.{ iVA DUCTS limit \\ TED, plaintiff, m si I \\ nt-HOMES LTD., defendant, and S.B.FREED, defendant es-qual.\"Subdivision 279 of original lot No.95 (95-279) of the official plan ami book of refcren«-«' ol the parish of Montreal\".\"Subdivision 280 of original lot No.95 (95-280) of the official plan ami book of reference ol ll»' parish of Montreal\" which are located in the city of Côte St-Luc, district of Montreal.\" To be sold at my office, in the city of Montreali on the EIGHTEENTH dav of the moid h «»f MAY 1907, at ELEVEN o'clock in the morning.Bernard Sarrazin, Q.C., Sheriffs Office, Shérif Montreal, April 10, 1907.I0301-O QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April U,, 1907, loi.99, No.t:> 2575 Fieri Facias de Terris Cour Supérieur* District de Montréal Montreal, à savoir; l QOCIÈTÈ CENTRALE \\n 726 III.{ & D'HYPOTHEQUES \\ ET DE LOGEMENT, de-mi,n,l, r.suc, n ASSOCIATED ENTERPRISES (19(14) LTD., défenderesse, et ARMAND OA-(i\\o\\.défendeur es-qualité.In emplacement ayant front sur la rue leuillot, en la cité de Montréal-Nord, connu et désigné comme étant le lot numéro vingt-trois de la subdivision officiels du lot originaire numéro onze (11-23) de» plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault au Récollel.borné comme viiil i u Iront vers le sud-ouest par la rue portant le numéro cadastral 11-7; en arrière vers le nord-est par une partie du lot numéro S; d'un côté ver» le sud-est par le lot numéro 11-24 et de l'autre côté vers le nord-ouest par le lot numéro 11-22, mesurant trente-quatre peids (.'14') «le largeur par des profondeurs de quatre-vingt\" -nii/e pieds (01') dans sa ligne sud-est et quatre-vingt-dix pieds (90') dans sa ligne nord-ouest, et contenant en superficie trois mille soixante-dix-sept pieds carrés (3.077 pi.car.) mesures anglaises et plus ou moins.Avec bâtisses dessus érigées ne portant pas de numéro civique présentement.Le mur nord-ouest de ladite maison est mitoyen.Tel «pie le tout se trouve présentement sans exception ni réserve et sujet à toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou ocultes.attachées audit immeuble, et plus s|>écialcmcnt à la servitude en faveur de la compagnie de Téléphone Bell du Canada et al, enregistrée au hureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1,843,672.» Pour cire vendu à mon bureau, en la ville de Montréal, le DIX-NEUVIÈME jour du mois de MAI 1007.à DIX heures du matin.Le Shérif.Bureau du Shérif.Bkknakd Sahhazin.eu.Montréal.le 10 avril 1067.19302-O Fieri Fucias de Terris four Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, à savoir: ( QOCIÊTÊ CENTRALE No 726 117.ove described ami on the north-west by the lane of twelve feet on Stc-Marguerite Street, the whole as indicated on a drawing of the terrain above described an«l annexed to the draft of a deed of sale by Robert MacKay et al to Mr.Wilfrid Nantcl, passed Iwfore Me A.C.A.Bissonnette, notary, on Septeml>er twenty-seven one thousand nine hundred and seven (1907) copy of which has been registered at the registry office of Hochelaga and Jacques-Cartier under number 138-072 to withdraw however from the said emplacement the strip of land forming part of said lot number fifteen hundred and twenty (1520) of the parish of Montreal, which has been sold to the city of Montreal, by deed of sale passed before Me Victor Morin, notary, on May 11, 1909, copy of which has l>een registered by statement at the registry office of the counties of Hochelaga and Jacques-Cartier, under No.180764.With the buildings thereon erected, bearing civic numbers 917 to 927 of the Stc-Marguerite Street; Such as the whole exists presently, with all the servitudes active and passive, apparent or occult attached to the said immoveable.To Ik* sold at my office, in the city of Montreal, on the EIGHTEENTH day of the month of MAY, 1967, at TEN o'clock in the forenoon.Bernard Sarrazin, q.c.Sheriff's Office, Sheriff.Montreal, April 10, 1967.19300 PONTIAC Canada \u2014 Province de Québec District de Pontiac »mr Supérieure, I \"D OGER LASALLE, mar-No 0106.\\ *V chaud du canton de ' LTle du Grand Calumet, PONTIAC Canada \u2014 Province of Quebe«' District of Pontiac Superior Court, ( \"D OGER LASALLE, mcr-No.6106.\\ *^ chant of the township of 'LTle du Cram! Calumet. 2678 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'EllEC, lô avril 1907, 99' année, n° U \u2022 listrict de Pontiac, demandeur, m LAURENT BÉRARD, de L'Ile du Grand Calumet, district de Pontiac.« Entièrement et eu particulier uu certain morceau de terre connu et désigné connue lot numéro dix-scpt-B ( 17-H), dans le premier rang (1), selon les plan et livre de renvoi officiels pour le canton de Grand Calumet, dans le district de Pontiac.avec toutes les bâtisses decSUl érigées et tous les membres et appartenances y appartenant.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Pontiac à Campbell's Mav, P.Q., MARDI, le SEIZIEME jour de MAI, 1967, à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif, Bureau du Shérif, Joskimi D.Si.ovx.Campbell's Bay.P.Q.le 7 avril 1987.19807 district of Pontiac, plaintiff, m LAI RENT BÉRARD, of L'Ile du Grand Calumet, district of Pontiac.\"All and singular that certain parcel of hind known ami designated as lot number seventeen.!) (17-B), in the first range (1), according In t|l(.official plan and book of reference in ami for tin township of Grand Calumet, in the district of Pontiac, together with all buildings thcrcupos erected and all members and appurtenance] thereto belonging.\" To be sold at the Registrar's Ollice for the COUnty f Pontiac in Campbell's Bav.P.Q., on TUESDAY the SIXTEENTH day of M A >i.i%; at TEN of the (dock in the forenoon.Joskimi I).Sloan, Sheriff's Ollice.8lu riff.Campbell's Bay, P.Q.April 7.1967 10307-0 QUÉBEC Fieri Facias Québec, à savoir:/T A CITÉ DE QUÉBEC, Cour Supérieure, ) contre SUCCESSION No 148401.\\ DE PEU I.ALPHONSE f DIONNE.« 1° Un emplacement situé sur la rue La vigueur, connu et désigné sous le numéro trois mille six cent soixante et un (8661) partie du cadastre du Quartier St-Jean dans la cité de Québec, borné au nord-est par le lot trois mille six cent soixante-deux (3602), au sud-est par le lot trois mille six cent trente-huit (8638), au sud-ouest par le résidu dudit lot trois mille six cent soixante et un (3081), au nord-ouest par la rue La vigueur.Mesurant soixante-quatre pieds et cinq dixièmes (64.51) au nord-est, soixante-quatre pieds et six dixièmes ((il.0') au sud-ouest et vingt-et-un pieds et trois dixièmes (21.T) de largeur.Contenant en superficie: mille trois cent soixante-quinze pieds carrés (1.37\")'), mesure anglaise.* Pour être vendu au bureau du Shérif, à 51, nie DesJardins, Québec le DIX-NEUVIÈME jour de MAI, 1907.à DIX heures de l'avant-midi.Le Shérif-Ailjoint.Bureau du Shérif, Ai.rert E.Racette.Québec, le 12 avril 1967.19308-O R O U Y X \u2014 NO II A N 1) A QUÉBEC Fieri Faeiae Quebec, b.wit : ( 'TMIE CITY OF Ql RBEC, superior Court./ *> against THF.ESTATE No.148-901.i OF THE LATE J.ALPHOX-( SE DIONNE.\"1.An emplacement situated on Lavigueut Street, known and designated under number three thousand six hundred and sixty-oiu .\\f land known and designated as being lot nuinliers two hundred and eighty-two (282) ami two hundred and eighty-three (283) block forty-one (41) of the official plan and book of reference of the township of Rouyn, with buildings constructed t hereon.circumstances ami dependencies. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 16, 1967, Vol.99, So.15 2570 Pour être vendu au bureau du régistruteur To lie sold ut I lie ollice of t lie registrar at the m Palais de justice de Rouyn, le DIX-HUI- Court House of Rouyn, on the EIGHTEENTH TIÈ.MK jour 06 MAI, 1907 à TROIS heures de day of MAV.1997.ut THREE o'clock in the I'tpri midi, afternoon.Le Shérif, Diams LaFBBNIXBE, Bureau du Shérif, Diams Lafhkmkki:.Sheriff's OHiee, Sheriff.liniiwi-Norundu.OB 7 swrll 1007.19309-O Rouyn-Norundu.April 7, 1997.19309 INDEX No 15 \\|{|{i: IKS en Conseil ORDERS in Council IT'.i Aiiichage du prix des repas a l'extérieur des restaurants et des salles à munger.2527 179 Posting of the price of meals outside restaurants and dining halls.2527 !.:{:; Impôt sur la vente en détail, obligation pour les personnel visées par l'article 10.de tenir une comptabilité et de conserver certains documents.2520 \u2022 Retail Sales Tax Act, obligation for persons subject to the provisions of section 10 to keep hooks and to preserve certain documents.2520 i;:i I Exposition Universelle de 1907, certaines concessions fiscales au Pavillon Chrétien Inc.2522 (134 Universal Exhibition of 1967, certain fiscal concessions granted to the Christian Pavilion Inc.2522 lis:; Pood Regulations.2507 083 Règlement sur les aliments.2507 733 Règlement concernant le droit et la procédure d'appel en matière de classement.2525 733 Regulation concerning the right and procedure of appeal in matters of classification 2525 003 Employés «le garages, Shawinigan.2523 063 (iarage Employees, Shawinigan.2523 tSSEMBLÊE MEETING Alma It Jonquièrc Railway Company (The).2533 Compagnie «lu chemin de fer Alma & jonquièrc (La) .2533 ASSOCIATIONS coopératives COOPERATIVE Associations \\.dation coopérative d'habitation de Dolbeau (Soin-Same ch.).25114 Association coopérative de consommation de Deux-Montagnes (Formation).2534 Association inoperative des étudiants de St-Jean Eudes (Formation).253)1 Two Mountains Consumers' Cooperative Association (Formation).253 I AVIS divers MISCELLANEOUS Sotices Abramovitch, Leon (Dem.-Appl.).2534 Blouin, Steve (Acc.-Grant.).2535 Brand, Erwin, Oravsky (Acc.-Grant.).2535 Chiang, Ark-Xgin (Acc.-Grant.).2534 Chin.William Voke-Koon (Acc.-Grant.).2535 Cimichella, Joseph René (Acc.-Grant.).2535 Fabrique de la paroisse St-Vinctent-de-Paul.2534 Fabrique of the parish of St-Vincent-dç-Paul.2534 Garbish, Alfred (Acc.-Grant.).2535 Gee, King-Vim (Acc.-Grant.).2535 ban,.Yen-lip (Acc.-Grant.).2535 Landy, William (Acc.-Grant.).2530 Loo, ( bib, Jom (Acc.-Gran t.).2586 \u2022Mad.rwslci, Alexander (Dcm.-Appl.).2588 Narvey, Irving, (Acc.-Grant.).2530 Olyarchuk, Alexander, Nicholas (Acc.-Grant.).2530 Parent, Joseph, Jacques, (idles, (Acc.-Grant.).2638 Parish of Ron-Pasteur de Manneville, Abitibi-East, (Same ch.).2537 Parish of Saint Mary.2537 Paroisse «le Saint Mary.2537 Paroisse «lu Ron-Pasteur de Manneville, Abitibi-Est, (Som ch.).2537 Ross, Sydney (Acc.-Grant.).2030 Roy, Albéric (Dent.- A ppl.).2534 Skurnik, Harry, (Acc.-Grant.).J§38 Solomon, Albert, (Acc.-Grant.).2530 Valade.Antonio (Acc.-Grant.).253\" * alade, Joseph George, (Acc.-Grant.).2537 Valade, Joseph Paul, (Acc.-Grant.).2537 CAISSES SAVINGS Caisse d'économie des employes Dom- ¦Mpargne et de crédit and credit unions _ tar D°!beau (Fonnation) 2538 ( aissc d économie des employes «le 1 II«»- Caisse d'économie des employés de pital St-Jean de Dieu (Formation).2538 General Motors {Formation) *.2537 Caisse populaire Morin (Lu) (Formation) 253.S 2580 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, là avril 1907, 99' année, n' ir, < :ok Inc.2539 Grocter (Ren) Holding! Ltd.2539 Kaz of ( anada Ll«l.2539 Lefebvre (Laurentien) & Fils limitée 2539 Lorman Realty Inc.2540 Montbeliard ltée.2540 Olympic Associates Inc.2540 Perri-Ann Lingerie inc.2540 Rainbow Vending Machines Inc.2540 Ruby Foo's Entcrpiises Ltd.2539 Sociéta Femminile Caserta.2540 Bunnyiide Holdings Limited.2540 Divert* Miscellaneous Café Tropicana inc.(Dir.).2544 Century Automotive Corporation (Dir.) 2544 Compagnie Esta limitée (La) (Dir.).2543 Comptoir de Charité inc.(Bègl.-Bylaws).2543 Compagnie Esta limitée (La) (Dir.).2543 Esta Company Limited (Tut) (Dir.).2543 Farnham Itecreation Society Inc.(The) (By-laws).2543 Groupe «les Espadrons, inc.(liegl.-Bylaws).2543 Imprimerie des Forges ltée (Dir.).2544 Laboratoire Cherrier limitée (Annul.revocation).2544 Little Ones' Car Club Inc.(The) (Bcgl.-By-laws).2543 Loisirs «le Farnham inc.(Les) (Itcgl.) .2543 Misskmarics of Pont-Viau (The) (Bylaws).2544 Missionnaires de Pont-Viau (Les) (llègl.) 2544 Mouvement récréatif «le N.-l).du Sacré-Coeur (Dir.) (Big-Bylaws).2544 Place Ronaventure inc.(Dir.).2544 Vilbois Lumber Ltd.(Dtr.).2545 Lettrée patente» Letters Patent Action civique de Sherbrooke inc.(L').24S9 Aitken Studios Ltd.24S9 Allaire & Laguc inc.24S7 Amis du Musée «l'art contemporain (Les).24S7 Anglo-French Enterprises Inc.2487 Association des fonctionnaires des Allai res culturelles (AFAC) (I/).j|NS Association des Loisirs de St-Davi.l il'Yamaska inc.21v» Association des parents de la Région Yamaska.Jjss Assurances .L-R.Lepage inc.(Les) 2489 Ra Ra Wool Shop (Montreal) Inc.2480 Rachand (Antonin) & fils ltée.2489 Rlaquière (P.) construction ltée.2190 Rra«ly Realties Corporation.2190 C.P.C.Québec inc.2490 Café «le la Concorde inc.2101 Camden Realties Limited.2 01 Canadian Hearing Society of Quebec (The).3503 Centre éducatif Laurentien inc.(Lei.2I'M Châteauguay Regional Shopping Plaza Merchants' Association.2192 Cité Jeunesse inc.3408 Club de ('liasse et de Pèche Maska inc.2192 Comité «les citoyens «le l'aire No 10 (Le) 2493 Concessions «lu Village International inc.2493 Corporation financière Laurentienne (La).2483 Distributeurs Lasalle inc.2191 Fondation Simard.2481 Hank's Automotive Centres Inc.2494 Hôpital LebeL.2495 Ht\"»tel Desjanlins ltée (Correction).2506 Industriel Valdex limitée (Les).249.\") Institut «les Sourds de Charleshourg inc.2195 Ital Montreal Construction Ltd.2DM Lalmratoirc «lu Dr Renaud (Division Canada) inc.2496 Laine Longueuil Inc.2496 Lasalle Distributors Inc.2494 Lasalle Service Station Inc.2503 Laurentienne Financial Corporation 2493 Lepra inc.2497 Ligue «les Propriétaires Quartier St-François Ville Laval.2 191 Loisirs de Ungue-Pointe-iinanclic-Matin (1907) ltée.2550 (iiliuour (W.H.) Ltd.2549 Hillcath investment! Corporation.2550 Immeubles Donpro Incorporés (Les).2549 Immeubles Journaux ltée .2551 Imperial Farm Inc.2550 Imprimerie Montréal-Granby Press 1967) ltée.2551 Industrial Import Ltd.2548 Journaux Trans-Canada ltée (Les).2551 boa me.2549 Marché des Aubaines ltée.2551 Ml.Royal Academy of Language Ltd.2549 O'Brien Explorations Limited.2550 Sam>on.Ib-lair.Simpson, Kiddell Inc.2551 s.i
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.