Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 27 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1967-05-27, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 00* ANNÉE vol.e made at the cost of the interested parties, according to official rates.3.Specify the number of insertions.4.Pay cash and before publication for a«l-vcrtising copy according t«) the rates set forth below, exception when the Copy is to be published several times.It that event, the interested party shall pay upon receipt of his account ami before the secoml insertion: otherwise this insertion will be suspended without further notice ami without prejudice to the Queen's Printer who will refund any overpayment.5.Subscriptions, price of documents, etc., are payable strictly in advance.(').Remittance must be made to the order of the Department of Finance, by cheque or money order.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning; but the dead line for receiving notices, documents or advertising copy expires at noon on Wednesday, unless it is a holiday.In that event the dead line is noon, on Tuesday.Notices, documents or advertising copy not received on time will be published in a subsequent edition.Moreover, the Queen's Printer is entitled to delay the publication of certain documents, because of their length or for reasons of administration.8.Any demand for cancellation or any remittance of money is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, the interested parties are requested to advise the Queen's Printer before the second insertion, so as to avoid, for both parties, onerous costs of republishing.Publiée par le Gouvernement de la Province / Published by the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, roch lefebvre, Queen's Printer \u2014 Québec GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 27 mai 1067, 09f année, n M Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, |)our chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $1 des 100 mots.l'Ai'm plaire séparé: 40 cents chacun.Feuilles volantes: $1.50 la douzaine.Abonnement: $10 par année à compter de janvier.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis mit la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertion, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seul fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Imprimeur de la reine, Rocn Lefebvre Hotel du Gouvernement.Québec.6 mai 1962 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, foi < version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc, at double rate.Translation: $1 per 100 words.Single copies: 40 cents each.Slips: $1.50 per dozen.Subscriptions: $10 |>er year from January N.B.\u2014 The figures at the bottom of noticei have the following meaning: The first figure refers to our document number; the second to that of the edition of the (luvtu for the first insertion; the third to the number ol insertion, and the letter \"o\" signifies thai the copy was neither our composition nor our translation.Notices published but onee are followed only by our document number.Rocn Lbfbbvbb, Queen's Printer Parliament BuUcUDJJBi Quebec.May 0, 1002 13377 l-.'.j.I.e Ministère des Postes, a Ottawa, a autorisé 1'afTranchissement en numeraire i't l'envoi oommi de deuxième classe de la présente publication.Authorised as second class mail by the Poet Office Department.Ottawa, and for payment of postage in cash.Lettres patentes A A >\\ leaociatee Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour «l'avril 1067, constituant en corporation: Andrew Kniaseff, propriétaire «l'une série «le voitures, 0530, Mountain Sights, Wilfrid N«»th.mécanicien, 4360, Old Orchard, tous deux «le Montréal, et .Ion kosorwich.avocat, 2100.Guertin, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Paire le commerce «le toutes sortes d'outillage d'enregistrement automoteur, jaugeurs.compteurs «le vitesse.v\\ les accessoires s'y rapportant, BOUS le nom «le « A & W Associates Incor|x>rate«l ».avec un capital t«>tal «le $40.000.divisé en 200 actions ordinaires «l'une valeur au pair de $100 chacune et 200 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $100 chacune.Le siège social «le la coni|>agnie est 1270, rue MacKay.Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Sniis-seerétaire de la province, Raymond Doi ville.10822 1039-07 I.' Unit loir St-Jacques inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Ix>i «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en «latc «lu 12e jour «l'avril 1907, constituant en corporation : Gervais Robert, Saint-Jacques, Léon Mercier, Saint-Roch-dc- Letters Patent A & W Associates Incorporated Notice is given that under l'art I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day «>f April.1087, have been issued by the Administrator «»f the Government f $10 each and into 9,000 pre.ferred shares of $10 each.The head Office of the company is al I.a.K|.chemin, judicial district of Beauce.Raymond Dot \\ n.i i.Assistant Secretary of the Provint* I0S22 1449457 Beacon Hill Swimming Pool Club Notice is given thai under Part 111 ul th.Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of April.1907.have been issued by tile Administrator «>f the Government of tile Province to incorporate a corporation without share capital: Thomas D.Moore, accountant.247 Mrulou Street.Wallace, D.O'Connor, kales manager.165 Chartwell Crescent, Ronald heck, I09< hart well Crescent.Alan Penny, l73An«lover Road, Timothy .1.Scott, 163 Bisley Street, all three executives, Alex Soroka.professional engineer.127 Creswell Drive, and David A, !{.Murray, chartered accountant, Is\" Andovci Road, all seven of Beaconsfield, for the following pun loses: To establish, maintain and conduct a swimming club, under the name of \"Beacon Hill Sw imming Pool ( \"hih\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporal ion nia\\ nun and hold is to be limited ( $150,000 The liead office of the corporal ion i> ul II.;i consfleId, judicial dial rid of Montreal.Raymoko Doi villk, Assistant Secretary of the /v 19822-0 1196-67 Rond Textiles Ltd.Notice is given that under Pari I oi ike Companies Act.letters patent, bearing date the 7th day of April.1067, have been issued bj the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Harry Miller, merchant, 2535 St-Louis Avenue, Ren Schaffer, manufacturer, 2l7ô Major Avenue, both of Saint-Laurent, Israel Messinger, chartered accountant, 1400 McGregor Avenue, Montreal, and Philip Shrague Garance, advocate, \">ô77 Alpine Avenue, Côte Saint-Luc, for the following purposes To deal in clothing and wearing apparel ol all kinds, under the name of \"Bond Textiles Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The bead office «>f the company i> at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doi vii.i.i .Assistant Secretary of the Protiiia 19822-0 1547-67 Routiquc «les Tissus inc.Avis est «humé qu'en vertu «le la première partie de la Lui «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «!«\u2022 la province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 12e jour «l'avril 1907.constituant en corporation: Pierre Deschènes, 4283, me Bertrand, Joseph Lafond, 165, 5c Rue.tous deux avocats, «le Shawinigan, et Marie-Andrée Landry, secrétaire, fille majeure.Saint-Etienne-des-Grès, pour les objets suivants: Faire le commerce «le tissus «le toutes sortes, sous le nom «le « Routi(|tie «les Tissus inc.», avec Rontiqiie des Tissus inc.Notice is given that limier Part 1 «>\u2022 II\"' Companies Act.letters patent, bearing date the 12th day of April.1067, have been issued by the Administrator of the Government «»f the Province, incorporating: Pierre Deschènes, 4263 Red rand Street.Joseph Lafoiul, 155» 5th Street, both lawyers of Shawinigan, ami Marie-Andree Landry, secretary, fille majeure, Saint-Etienne» «les-Grès, for the following purposes: To «leal in material of all kinds, under the name of \"Boutique «les Tissus inc.\".with a totsl QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 97, 1967, Vol.99, No.91 3251 un i-u|»ilul total de §10,000, divisé en 100 actions ordinaires de 1100 chacune.Le siège social de la compagnie eal à Shawi-liigon, district judiciaire de Saint-Maurice.Le Sous-sccrétairc de lu province, Raymond Douvtllb.I9S22-0 1109-07 capital stock of §10,000, divided into 100 common shares of $100 each.The head office of the company is at Shawi-uigtin, judicial district of Saint-Maurice.Raymond Douvillk, Assistant Secretari/ of the Province.10822 1100-67 Itrocklclmrst iCorporation c>t donné qu'en vertu de la première partie de la Loi dei compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres I» ten tes, en date du 21e jour de mars 1907, constituant en corporation: Allan Marcus, avocat, 1212, avenue des Pins, Lucille Blagdon, «ccrétaire, fille majeure, 101.57.D'Auteuil, tous deux de Montreal, et Abel Sehck, avocat, 1605, du min Norway.Mont.Royal, pour les objets sui vanta: Exercer le commerce d'une compagnie de placements, sous le nom de « Itrocklclmrst Corporation .avec Un capital total de $40,000, divise un 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune, le siège social de la compagnie eat à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.R iymond Dor vii.lk.0H2J 1238-67 Rrockleliursl Corporation Notice is given that under Part 1 of the Companies Act.letters patent, hearing date the 21stday of March, 1907, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Allan Man-us, advocate.1212 Pine A venue.Lucille Blagdon, secretary, fille majeure.10437 D'Auteuil, both of Montreal, and Abel Selick, advocate.1605 Norway Road, Mount Royal, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Hroekleliurst Corporation\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of ¦SI each and 200 preferred shares of $100 each.The head Office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douviixk, Assistant Secretari/ of the Province.(08224) 1238-67 c \\.s.Investments Ltd.est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur \u2022lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'avril 1907, constituant en corporation : Joseph Tarasofsky, 1572, Coolbrook, William Levitt.4809, Dornàl.tous deux de Montréal, et Jack Shayne, 5871, Mclling, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, |Miur les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, bous le nom de « C.A.S.Investments Ltd.with a capital stock of $40,000, divisé in 1.1100 actions ordinaires de SI chacune et ¦'> actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le Stius-seerétaire de la province, Raymono Dor vii.i.k.1504-07 C A.S.Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, hearing date the 17th day of April, 1907.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Joseph Tarasofsky.4572 Coolbrook, William Levitt.4860 Dornal.hot h of Montreal, and Jack Shayne, ÔS71 Mclling.Côte Saint-Luc.all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"C.A.S.Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 39.000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond DoU ville, Assistant Secretari/ of the Province.10822-o 1504-07 Caritas Gaspé Avis est donné (m'en vertu de la troisième parlie de la Loi des compagnies, l'administrateur 'lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'avril 1907.\"\u2022listituant en corporation sans capital-actions: Jean-Paul Duguay, comptable agréé, Roch Roy, avocat, et Raymond Founder, secrétairc-tré-\"«irier.tous trois de (Jaspé.]*>ur les objets suivants: Promouvoir les oeuvres d'Église, diocésaines el paroissiales, à caractère religieux, social et cducationnel, sous le nom de «Caritas Gaspé ».Le montant auquel sont limités les revenus annuels provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 1200,000.Le siège social de la corporation est à Gaspé, district judiciaire de Gaspé.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.19822-0 1375-07 Caritas Gaspé Notice is given that under Part 111 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of April, 1907, have been issued by the Government Administrator of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean-Paul Duguay, chartered accountant, Roch Roy, advocate, and Raymond Fournicr, secretary-treasurer, all three of Gaspé.for the following purposes: To promote Church, diocesan and parochial works of a religious, social and educational nature, under the name of \"Caritas Gaspé\".The amount to which the annual income from the immovable property which the corporation may acquire and hold is to lx' limited, is $200.000.The head office of the corporation is at Gaspé, judicial district of (Jaspé.Raymond Doi villk.Assistant Secretary of the Province.19822 1375-07 GAZETTE OFFICIELLE DE QU fill EC, 27 mai 1997, 99* ami*, 91 Centre» Agricoles du O/uébec inc.Avis es! donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé del lettre! patentes, en date du 13e jour d'avril 1007, constituant an corporation: Claude Grignon, avocat, 2K5, Marcotte, Saint-Laurent, Pierre Vé/.ina, trésorier, 141, boulevard Saraguay, Pierrefonds, et Louis-Philippe Poiilin.secrétaire, 8438, Peterborough, Anjou, pour les objets suivants: Faire le commerce des utilités de terme, sous le nom de « Centres Agricoles du Québec inc., avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de §10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.l.e Sous-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.10822-n 1433-67 Charcuterie Ro> inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour d'avril 1967, constituant en corporation: Raymond Roy.homme d'affaires, Claudette Rodrigue, ménagère, épouse contractucllciucnt séparée de biens dudit Raymond Roy.tous deux de Saint -Anselme.Jacques Goulet, comptable, 1204, Beau-Pré, et Jacques ( 'airier, homme d'affaires, 900, boulevard Pic XII, ces deux derniers de Saintc-Foy.pour les objets suivants: Paire affaires comme épiciers-bouchers.BOUS le nom de ' Charcuterie Roy inc.avec un capital total de $100.000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 000 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Anselme, district judiciaire de Rcauce.Le Sniis-.secrétaire de la province, Raymond Douville.19822-0 1040-07 Clwisliao Research Foundation Inc.Fondation chrétienne pour la Recherche inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de mars 1967, constituant en corporation sans capital-actions: John Buell, professeur.5171, avenue West more.Leonard James Crowley, prêtre directeur.400, ouest, boulevard Dorchester.Marga Filecn McGrath, travailleuse sociale, épouse de Pasqualc D'Angelo.21110.rue Wellington.William Dyson, travailleur social, 70.nord, avenue Railantyne, Harry Goldsmith, biophysicien, 215, avenue Rcdhrook, Rcrnard MaeDonald.prêtre de paroisse.1650, rue Valois, Jeanne Vernon Heatboott, ménagère, épouse de Joseph Stanley Michencr, 533, avenue Rerwiek, Georges Predelli, prêtre.3484, rue Peel.Hugh Scott, médecin, 5005, avenue Trans Island.Gerald Wilfrid Tait, S.J.prêtre, (régistrateur collège Loyola), 7141, rue Sherbrooke, tous les dix de Montréal, Cîerald Fitzgerald, avocat.810, 37e Avenue, Lachine, Arthur Francis Knowlcs, contrôleur, 70, avenue Brunswick, Reaeonsficld.Peter Macklem, médecin, 20150, chemin Lakeshore, Baic-dTrfé, Lco MacGillivray, éditeur journaliste, 38, Macauley, Saint-Lanihert.Agnes Victoria, Kbbs Canavan, ménagère, épouse de Cuthbert Rcrnard Shipton, 4.Strathmore Crescent, Dorval, et Joseph Wen- Centres Agricoles du Québec inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, hearing date tl|C.13th day Of April, 1967, have been issued l.v the Administrator of the Government of the Prov.ince.incorporating: Claude Grignon, lawyer 285 Marcotte, Saint-Laurent, Pierre Vézina treasurer, 141 Saraguay Roulevard, Pierrefonds, and Louis-Philippe Poulin, secretary.8438 Peterborough, Anjou, for the following purposes: To deal in farm utilities, under the name of \"Centres Agricoles du Québec inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 com.mon shares of S10 each.The head of lice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Dm ville, Assistant Secretary of the Pr I0S22 1433-67 Charcuterie Roy inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing dati the 13th day of April.1007.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Raymond Roy.hiisinm- man.Claudette Rodrigue, housewife, ftifi COI tractually separate- as to property of said Raymond Roy.hot h of Saint-Anselme, Jacques Goulet, accountant, 1204 Beau-Pré, and Jacques Carrier, businessman, ooo Pie Nil Boulevard, the latter two of Saintc-I'oy.for the following purposea: To carry on business as groccrs-hutcliers, under the name f \"Charcuterie Roy inc.\", with a total capital stock of 8100.000, divided into 400 common shares of $100 each and 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company is al Saint-Anselme, judicial district of Reaucc.Raymond Doi villk, Assistant Secretari, of the I'r.19622 1640-67 Christian Research Foundation Inc.Fondation chrétienne pom- la Recherche Inc.Notice is given that under Part ill ol the Companies Act.letters patent, bearing date the 21st day of March, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: John Buell, professor.5171 Westmore Avenue.Leonard James Crowley, priest administrator, 460 Dorchester Roulevard West.Marga Eileen McGrath, social worker, wife of Pasquak D'Angelo.2139 Wellington Street.William Dyson, social worker, 70 Railantyne Avenue North, Harry Goldsmith, biophyscist, 215 Bedbrook Avenue, Rcrnard MacDonald.parish priest, 1050 Valois Street.Jeanne Vernon Heothcott, housewife, wife of Joseph Stanley Michciier.633 Berwick Avenue.George Predelli.prist.34w Peel Street.Hugh Scott, medical dint or.5905 Trans-Island Avenue, Gerald Wilfrid Tait, S.J., prist (Registrar Loyola College), 7141 Sherbrooke Street, all ten of Mont irai.Gerald Fit/Gerald, lawyer, 810, 37th Avenue, Ladiine, Arthur Francis Knowles, comptroller.70 Brunswick Avenue, Rcaconsfield.Peter Mack km.medical doctor, 20150 Lakeshore Road.Ilsic-dTrfé, Leo MacGillivray, journalist editor, 38 Macauley, Saint-Lambert, Agnes Vidons Ebbs Canavan, housewife, wife of Cuthberl Bernard Shipton, 4 Strathmore Crescent, Don's!, QUEBEC OFFICIAI GAZETTE, Mai/ 87, 1967, Vol.99, Nû.81 3253 cpsIus Tomeeki, gérant en relation! éducatives, H, chemin Elmwood, Senneville, pour loi objets ituivants! Stimuler «-t participer par ia recherche et le travail dans les domaines de lu religion, de l'éducation el l'action sociale, sous le nom de Christian Research Foundation lue.Fondation chrétienne pour la Recherche inc.».l.e montant auquel esl limitée la valeur de la propriété m\"c 'a corporation peut posséder et détenir est de 1100,000.I.r siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.r Sous-secrétaire de la province, Raymond I )ou v i LUE.[9822 1.577-07 Club de Golf Birchdale Birchdale Golf Chili Ivis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, eu date du 21e jour de mars 10(i7.constituant en corporation: .l.-Kugèue Soude, comptable, 117.Cothran, Auréle Roily, comptable agréé, Gaétan Roily, notaire, tous deux de 711.Sacré-Coeur.Jean-Paul Gauthier, surintendants, 11.West, et Pierre Lessard, gérant, 701.Hébert, tous cinq d'Alma, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif el promouvoir le s|m>rt du golf, sous I to property of the said Leonard Denis.both ,,f 1100 Bouchette, Montréal, and Sara Grusllka, housewife, wife separate as to property ol Mojze Grushka, 1065 St.Aubin, Saint-Laurent, for the following purposes: To cany on the business of an electrical and electronics company, under the name ol I celsior Lamp Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $] each and 2.000 preferred shares of $10 each The head office of the company is at M judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretari, of the Pro 19822-0 1642-67 Fenêtres Vcnt-O-Matic, I tee Yeiit-O-Matie Windows, Lid.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement i the Province, incorporating: Maurice Martel, lawyer and Queen's Counsel, L301 St-Viateur-Wcst, Outremont, Lucille Roy, secretary, wife «>f Jean-Claude Biais, 21 (idles Street.Sainte-Thé-rèse-West, and Fernande Perreault, secretary, fille majeure, 2825 St-Joseph Boulevard East, Montreal, for the following purposes: To deal in windows, furniture, doors and novelties of all kinds, under the name of \"Fenêtres Vent-O-Matic, Itée - VentO-Matic Windows.Ltd.\", with a total capital stock f 810.000.divided into 400 common share- i 1 each ami into 3,600 preferred shares ol f April.1987, have been issued by the Administrator «>f the Government ol the Province to incorporate a corporation without share capital: Maurice Ling, industrialist, 21 Gingraa St., Emile Ducharme, employee, 34 Notre-Dame St., ami Marcel Ream let, traveller, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 27, 1967, Vol.99, No.U v.irl boulanger, tous trois de Warwick, pour lea objets suiviuils: Fournir à eut acquérir et posséder irporation, est de 1400,000.l.e siège social de la corporation est ji, rue Gingras, Warwick, district judiciaire d'Artha- l.aska.Le Sous-secrétaire île la province.Raymond DoUvUXB.19822-0 102447 Sidney Friedman Inc.Avis esl donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, l'administra* Leur du gouvernement de la provint a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour d'avril constituant en corporation: Sidney Friedman, vendeur.( iertrude M inlz.ménagère, épouse séparée de biens dudit Sidney Friedman, et Murray Dankoff, vein leur, tous trois de 5852, tin Ferncroft, Hampstead, pour les objets suivants: Exercer commerce comme agent de manufacturiers, agent à commission, agent de ventes, représentant de ventes, courtiers et distribu-de manufacturiers, jobbers et pour toutes maisons commerciales canadiennes et étrangères, i! pour toutes autres personnes, firmes ou corporations, sons le nom de \u2022' Sidney Friedman lue.avec un capital total «le $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 360 actions privilégiées dune \\ alciir au pair «le 8100 chacune.L, dège social de la compagnie est ÔSÔ2.chemin Ferncroft, Hampstead, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond DOUVILLE.19822 1380-67 J.C.Gagnon inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le la province a accordé îles lettres patentes, en date du 31e jour de mars 967, constituant en corporation: Jean-Claude Gagnon, courtier en assurance, Marie Pouliu-Bisson, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit .Ican-( 'lande Gagnon.et Moorc, ménagère, veuve non remariée d'Oliva Gagnon.tous trois de Lac-Mégantic.pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom «le « J.C.Gagnon inc.», avec un capital total de 850.000.divisé en 1.000 \"lions ordinaires de 810 ciiactinc et en 1.000 'étions privilégiées de 810 chacune.l.e siège social de la compagnie est 237, rue 'aval.Lac-Mégantic, district judiciaire «le >aint-François.l.e Sous-sccrétairc de la province.Raymond Doc vii.i.k.19822-0 1390-07 < -oi i-, balk & Ash Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour d'avril 3265 11 Boulanger Blvd., all three of Warwick, for the following purposes: To give aged couples and aged persons of both sexes a home which will permit them tf the corporation is at 21 Gingras st .Warwick, judicial district ï Artha-baska.R \\YMoN II I >ol VILLI.Assistant Serretari/ of the I'rovinci .19822 1024-67 Sidney Friedman Inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the L3th day of April.1007.have been issued by the Administrator of the Government f the Province, incorporating: Sidney Friedman, salesman, (iertrude Mint/, housewife, wile separate as to property of the «aid Si Iney Friedman, and Murray DankolT.salesman, all three of 5862 Ferncroft Road, Hampstead.for the following purposes: To carry on business as a manufacturer's agent, commission agent, sales agent, sales representative, bnikers and distributors for manufacturers, jobbers and for Canadian and foreign commercial houses and for any other persons, linns or corporations, under the name of \"Sidney Friedman Inc.\", with a total capital stock of 940,000, divided into 5,000 common shares of a par value of 81 each ami 350 preferred shares «if a par value of 8100 each.The head office «>f the company is at 5852 Ferncroft Road, Hampstead, judicial district of Montreal.Raymond 1 >oi vn.i.i:.Assistant Secretary of the Province.19S22-o 1380-67 J.C Gagnon inc.Notice is given that under l'art I «>f the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of March, 1007, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Jean-Clam le Gagnon, insurance broker, Marie Poulin-Bisson, housewife, wife contractually separate as to property of said Jean-Claude Gagnon, and Eva Moore, housewife, unremarried widow of Oliva Gagnon, all three of Lac-Mégantic, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name «>f \"J.< '.Gagnon inc.\", with a total capital stock of 800,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and into 4,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 237 Laval Street, Lac-Mégantic, jmlicial district of Saint Francis.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretari/ of the Province.19*22 1306-67 Gottschalk & Ash Ltd.Notice is given that under Part 1 «)f the Companies Act, letters patent, hearing date the 5th day of April, 1907, have been issued by the Administrator of^the^Government of the GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 27 mai 1907, 99' année, n\" 21 3250 1007, constituant en cor juration: Clarence A.Fiske, 1230, avenue McGregor, Montréal, Charles F.Kmery, 227, Kli/.abeth Circle, Rosemèrc, et Yves Lau/on, 305, 3Se avenue, I.achinc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer un commerce d'imprimeur* généraux, sous le nom « le « Gottschalk & Ash Ltd., avec un capital total de 810,000, divisé en 10)000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 110 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montival.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Dou ville.10822 1252-07 C.K.Hébert & fils inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, !ratioii: Pierre La-lande, avocat.Charlotte Dulmis, ménagère, épouse séparée de biens dudit Pierre Lalande.tous deux «le 3000.boulevard Ste-Rose, Laval, et Ginette Huncault.secrétaire, fille majeure, 72S3, rue Rerri.Montival, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie «l'immeuble.de construction, «le placement et «le portefeuille 'holding), sous le nom de « Les Investissements Rivepierre ltéc , avec un capital total de 8200,000.divisé en 20 actions ordinaires de 850 chacune, 1,000 aidions privilégiées classe «A» de 81 chacune et en 1,980 actions privilégiées «lasse « B » de S100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3405, Place Decelles, app.304, Montival, district judiciaire «le Montréal.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond bonvii.uk.19822-0 1657-07 Isolation S.M.liée Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de mars 0.107, constituant en corporation: Steve Meny-hart, 0805, 23e avenue, Montréal, Fernand Pelle- Province, incorporating: Clarence A.Piske, 1230 McGregor Avenue, Montreal, ('hurles K.Kmery, 227 Elizabeth Circle, Rosemère, and Yves i.,m.eon, 365, 38th Avenue, Lachine, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as general printers, under the name of \"Gottschalk & Ash Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided ml,, 10,000 common shares of the par value of $| each and 3,000 preferred shares of the par value of §10 each.The head office of the company is at Muni, real, judicial district of Montreal.Raymond Doivii.i.i.Assistant Secretary of the Province.10822-o 1252-67 C.F.Hébert & fils Inc.Notice is given that under Part.I of the Companies Act.letters patent, bearing date tile 30th day of January.1007, have been issued |,v the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Charles-Edouard Hébert, Benoil Hébert, both florists, Maurice Hébert, accountant, all three of 405 Hébert Street.Saint-Joseph, county of St.Hyacinthe, and Richard Hébert, inspector, 2030, Turcotte, Saint-Hyacinthe, fur the following purposes: To carry «>u the business of flowvrs.garden products, bushes, vegetables, chemical fertilizers and manure, utensils, farm and garden equipments and building materials, under the name of \"C.F.Hébert & fils inc.\".with a total capital slock of 810.000.divided into 1.000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head ollice of the company is at Sainlc- Rosalie, judicial district f St-Hyacinthe.Raymond Dot villi .Assistant Secretary of the Province.19*22 229-07 Les Investissements Rivepierre liée Not ici- is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 17th day «>f April.1967, have been issued by the Administrator «>f the Government f the Province, incorporating: Pierre Lalande, lawyer.Charlotte Dubois, housewife, wife separate as to property of said Pierre Lalanile, both of 3000 Ste-Rose Boulevard, Laval, and Ginette Huneault, secretary, fille majeure, 7283 Berri Street, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Les Investissements Rivcpicrr-ltéc\", with a total capital stock of $200,000, divided into 20 common shares of 850 each.1.000 preferred class \"A\" shares of 81 each and into 1.980 preferred class \"R\" shares of 1100 each.The head office of the company is at 3465 Place Decelles, Apt.304.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doi-villi:.Assistant Secretary of the Province.19S22 1657-67 Isolation S.M.ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of March, 1907, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Steve Menyhart, 6805, 23rd Avenue, Montreal, Fernand Pelletier. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Mai, iff, 1007, Vol.00, No.21 3257 lier.'iti-IO, rue Charron, Domaine des Sahles, (tang Coniptois, Terrelnnine, tous deux ealorifu-geurs, et Guy Dumais, journalier, 1943, Wood-[and.Montréal, jmur les ohjets suivants: l'aire le eonnneree de toutes sortes de matières ,.u produits pouvant servir à l'isolation en général.>o us le nom de * Isolations.M .Itée , avec un capital total de 126,000, divisé en 260 actions ordinaires de $100 chacune.l.e liège Social de la compagnie est 6805, 23e avenue, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Sous-secrétaire de la province.Raymond Doi vu.m:.19822-0 1376-67 Jadran Publishing Ltd.est ilonné qu'an vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administre-i.m du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour d'avril 967, constituant en corporation: Stefan T.Du- Io.aiioc.médecin.2010.rue Ekers, Seymour Machlovitch, avocat.3495, rue Mountain, app.708, tous deux «h- Montréal, Marvin Ro-seidiek.avocat.335, Grcnfcll.Mont Royal, et Gisèle LeBlanc, secrétaire, épouse séparée «le biens de Marcel LcRIauc.1815, «le Rouchcr-ville.Saiiit-Rruu«i-«lc-Moiitarville, pOUT les objets suivants: Exercer un commerce «le propriétaires de journaux, imprimeurs «4 éditeurs généraux, sous le in un «le * Jadran Publishing Loi.avec un capital t.ital «le 140,000, divisé en 10,000 actions ordinaires «le SI chacune «'t 30,000 actions privilégiées «le Si chacune.Le siège Social «le la compagnie «'st à Montréal, district judiciaire «le Montival.Le Soas-sccictairc de la province.Raymond Doi vii.i.i.9822 1623-67 Les Jardins de la Calèche inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur «lu gouvernement «le lu province a accordé lies lettres patentes, en «late «lu lie jour «l'avril 1967, constituant en corporation: Rodolphe Rcrnard, entrepreneur-plombier, 43, rue de Bigarré, Victoriaville, Bernard Liboiron, hôtelier, 55, Préfontaine est, Sainte-Agathe-des-Monts, i ' Marcel Piché, commerçant.2053.boulevard I.allelic, Lafontaine.|xmr les ohjets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble, 'li construction et «le portefeuille I midi nu .-uis le nom «le « Les Jardins de la Calèche inc., ovec un capital total «le 810,000, divisé en 400 actions onlinaires de $100 chacune.l.e siège social «h- la compagnie est 22.rue Ste-Agathe, Sainte-Agathe-des-Monts.district judiciaire «le Terrclmnne.Le Sous-sccrétairc de la province.Raymond Doivii.i.k.19822-0 1002-07 A.Lamontagnc Électrique inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le la Loi des compagnies, l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé d« s lettres patentes, en date du 18c jour d'avril 1967, constituant en corporation: Armand La-montagne, inattre-électricien, Roger Lainonta-gne, étudiant, tous deux de 5996, rue Iberville, et J.-Roger Ouimet, technicien en réfrigération, 3040 Charron Street, Domaine des Sables, Rang Comptois, Terrebonne, both insulators, and Guy Dumais, labourer, L943 Woodland, Mont real, for the following purposes: To deal in all kinds of materials or products serving for insulation in general, under the name of \"Isolation s.M.ltéc\", with a total capital stock of $25,000, divided into 250 common shares of 8100 each.The bead «>fli«v of the company is at 6805, 23rd Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvxllb, Assistant Secretary of the Province.19822 1376-67 Jadran Publishing Ltd.Notice is given thai under Part 1 of the Companies Act, letters patent, hearing «late the 13th day of April, 1007, have been issued by the Administrator «>f the Government «if the Province, incorporating: Stefan T.Dubieanac, physician.2010 Kkcrs Street, Seymour Muchlo-vitch, advocate.3405 Mountain Street.Apt.708, lioth «if Montreal, Marvin Rosenhek, advocate, ;>:;.\") Grenfell, Mount Royal, and Gisèle LeBlanc, secretary, wife separate as to property «»f Marcel LeBlanc, 1815 de Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, for the following purposes: To carry «m business as newspaper proprietors ami general printers and publishers, under the name of \"Jadran Publishing Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 30,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district «if Montreal.Raymond Dot villk, Assistant Secretary of the Province.19S22-.1023-07 Lea Jardins de la Calèche inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 11th day «if April, 1907.have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Ro«lolphe Bernard, plumbing contractor.43 «le Bigarré St.Victoriaville, Bernard Liboiron, hotel-keeper, 55 Préfontaine Kast, Saintc-Agathe-des-Monts, and Marcel Piché, trader, 2053 Labelle Blvd.,'Lafontaine, f«>r the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and holding company, uniler the name of \"Les Jardins de la Calèche inc.\", with a total capital Stock «)f 810,000, divided into 400 common shares of $100.The head office of the company is at 22 Ste-Agathe St., Stc-Agathe-des-Monts, judicial district of Terrebonne.Raymond Dor villk.Assistant Secretari, of the Province.L9822 1602-67 A.Lamontagnc Électrique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of April 1907, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Armant! Lamontagnc, master electrician, Roger Lamontagnc, student, both of 5996 Iberville Street, and .1.-Roger Ouimet, refrigeration technician, 0044 Papincau GAZETTE OF'FICIELLE DE QUÉBEC, W mat 1907, 99' année, n° 21 :f the Province, incorporating: Joseph Tarasofsky, 4572 Coolbrook, William Levitt, 4869 Dornal, both of Montreal, Jack Shaync, 5S71 Melling, Côte Saint-Luc, ami Max Mendelsohn, 10 Renfrew, Westmount, all four a«lvocates, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Ma.,/ 27, 11)07, Vol.99, No.21 3259 Paire !«\u2022 commerce de toutes sortes de marchandises, sous le nom de « M & I) Class Tempering Ltd., avec un capital total de S 10,0011, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 11 chacune et 39|000 actions privilé-d'une valeur au pair de Si chacune.le siège social de la compagnie est à Saint-Laurent, district judiciaire «le Montréal.I.r Sous-secrétaire de la province, Raymond DouVILLE.19822 1618-67 Murtos inc.Avis est «humé qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour d'avril 1907, constituant «m corporation: Paul Leclerc, ugenl d'immeubles, 1681, rue Marcil, Gaétane Gagné, secrétaire, 611e majeure, lô.\">, rue Loinas, app.2, «-t Claude-D.Beaurivage, notaire, 2581, rue Maisonneuve, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie de placement el de portefeuille (holding), sous le nom «le Marios inc., avec un capital total «le $50,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale «le §10 chacune et en 100 actions privilégiées d'une valeur nominale «le §100 chacune, l.e sjége social de la compagnie «st à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.I.i Sous-secrétaire de la province, Raymond Doi vii.i.k.19822-0 1000-f $40,000, divided into l.ooo common share- of the par value of $1 each and 39,000 preferred shares of the par value of $] each.The bead office «>f the company is at.Saint-Laurent, judicial district «>f Montreal.Raymond Doi vii.i.k, Assistant Secretari/ of the I'rovinee.19822-0 1618-67 Martos inc.Notice is given thai under l'art I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 12th day «>f April, 1907, have been issued by the Administrator of the Government of the I'rovinee.incorporating: 1'aul Leclerc, real estate agent.1681 Marcil Street, Gaétane Gagné secretary, fille majeure lôô Loinas Street, apt.2.and Cluutle-D.Reaurivage.notary, 2ÔS1 Maisonneuve Street, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Martos inc.\".with a capital stock of §00.000.divided into l.ooo common shares of a nominal value of §10 each ami 100 preferred shares of 8 nominal Value of §100 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district «>f St.Francis.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretari/ of the Province.L9822 1600*67 Motel Ame/.on liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, l'administrateur du gouvernement «le la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 17c jour «h- mars 1907, ««instituant en corporation: Albert Bélanger, notaire, 7200.Hutchison, suite 303, Hélène Lagarde, secrétaire, épouse contractuelle-iiiiiil séparée de biens «le Pierre (liénier, 7202, Pie IX.et Fleurette Laporte, secrétaire, épouse «\u2022ont(actuellement séparée de biens de René Boudreau, 9617, Sackville, tous trois «le Montréal, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, tavernes, auberges, motels et restaurants, sous le nom «le * Motel Am.-son liée », avec un capital total de 810,000, divisé «-il 100 actions ordinaires «le §100 chacune el en 1500 actions privilégiées «le 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie est s2, rue \\olre-Dame, Re]>cntigny, district judiciaire dé Joliette.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.19822-0 7*3-07 Motcl Aniezon liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 17th day of March, 1007, have been issued by the Administrator «>f the Government of the Province, incorporating: Albert Rélanger, notary, 7200 Hutchison, suite 303, Hélène Lagarde, secretary, wife contractually separate as to property of Pierre Chénier, 7262 Pie IX, and Fleurette Laporte, secretary, wife contractually separate as to property «»f René Boudreau, 9017 Sackville, all three of Montreal, for the following purposes: To operate holds, taverns, inns, motels and restaurants, under the name of \"Motel Amazon ltéc\".with a total capital stock of §10,000, divided into 100 common shares «»f §100 each and into 300 preferred shares of §100 each.'Phc head office of the company is at S2 Notre-Dame Street, Itcpentigny, judicial district of Joliette.Raymond Dim ville.Assistant Secretari/ of the Province.19S22 783-07 Motel Paris inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour d'avril 1907, constituant en corporation: André Drouin, 60, St-Jacques ouest, Claudel Sirois, 5795, ''«¦«\u2022elles, tous deux avocats, de Montréal, Michel Bissonnette, avocat, 130, 17e Avenue, Lachine, '\u2022Marcel Charbonneau, secrétaire légal, 578, « illiam-David, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, motels, auberges et restaurants, sous le nom de « Motel Paris Motel Paris inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of April 1967, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: André Drouin, 00, St.James Street, West, Claude! Sirois, 579o^J>ecelles, both advocates, of Montreal, Michel Rissonnettc, advocate, 130, 17th Avenue, Lachinc, and Marcel Charbonneau, legal secretary, 578 William-David, Montreal, for the following purposes: To operate hotels, taverns, motels, inns ami restaurants, under the name of \"Motel Paris 8260 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 97 mai 1997, 99' année, n° 21 Inc., avec un capital total «h- 640,000, divisé en 4,000 actions ordinaires , 7e Avenue, ( écile Caron, épouse séparée de I,;.h- d'Auguste lloude, 302, rue Laurier, et Mireille Gaudet, épouse séparée de biens de ||.jiuald Rticsl, 701A, rue St-Pierrc, toutes trois secrétaires, de Drummondville, pour les objets suivants: l'aire affaires comme entrepreneurs en plom- Imrie, chauffage el en réfrigération, SOUS le nom de Plomberie Carignan & fils inc., avec un capital total de §10,000.divisé eu 1.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de §10 chacune et eu 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de §10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Drutn-lliondville, district judiciaire de Drummond./.,\u2022 Soiis-si¦erétaire de la province, Raymond Doiyillk.19822-0 722-67 Polcon Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur \u2022 iii gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1 le jour d'avril 1907, constituant en corporation: Raruch Pollack, 'ills.'), de Vimv, Aaron Pollack.000.Rockland.Isidore Greenbaum, 615, West Luke, all three advocates, Morris Shuter, accountant, 201, llarland, el Joyce Isaac, secrétaire, célibataire.955, Plymouth, tous les cinq de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer l'outillage à commande mécanique pour le traitement des eaux usées et l'outillage d'équipement pour enrayer la pollution, machinerie et piècesd'icelles, en faire le commerce sous le nom de « Polcon Corporation\", avec un capital total de §10,000, divisé- en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de §1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.c S,ois-secrétaire de la province, Raymond Doivillk.19822 1598-07 The bead office f the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ray.mon d Doi villi;, Assistant Secretari, of the I'rovinee.10S22 1582-07 Plomberie Carignan & tils inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 7th day of April, 1967, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Lucille Désunirais, wife separate as to property of Lucien Allie, lô.7th Avenue.Cécile Caron.wife separate as to property of Auguste lloude.302 Laurier Street, and Mireille Gaudet, wife separate as to property of Reginald Kuest, 701A St-Pierre Street, all three secretaries of Drummondville, for the following purposes: To carry on hysiness as plumbing, heating and refrigeration contractors, under the name of \"Plomberie Carignan & fils inc.\".with a total capital stock of §10.000, divided into 1.000 common shares of a nominal value of §10 each and into 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head ollice of the company is at Drummondville, judicial district of Drununond.Raymond Dor villk, Assistant Secretari, of the I'rovinee.19822 722-07 I'oh on Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of April.1907, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Raruch Pollack.00S5 de Vimy, Aaron Pollack.900 Rockland, Isidore Greenbaum, iis-secrétaire de la province, Raymond Douville.D822-0 1187-67 I es Produite chimiques de (Québec inc.Quebec Chemical Products Inc.\\>i> est donné qu'en vertu de la première paille de la Loi des compagnies, l'administrateur ,lu gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en dute du 12e jour d'avril 1007.constituant en corporation: Dr John Kane, chimiste, Serge Caudrcau, ménagère, é|x>use dlldil John Kane, tous deux de 1135, chemin Ste-Foy, Gustave Racine, chimiste, et Rolande l>iihé.ménagère, épouse dudit Gustave Racine, ces deux derniers de 310.«les Peupliers ouest, tous quatre de Québec, pour les objets suivants: Industrie et commerce «le produits chimiques de toutes sortes, sous le nom de * Les Produits chimiques de Québec inc.Quebec Chemical Products Inc.», avec un capital total île 810,000, i-, en 1,0011 actions ordinaires de $10 chacune.Le >iège social «le la compagnie est 250, rue I.e.Québec, district judiciaire de Québec.Le Soiis-sccrétuin de la province, Raymond Douville.0822-0 1012-07 Sio.ooo, divided into 20,000 common shares of a nominal value of SI each and into 2,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreul.RayMONd Douvillk, Assistant Sccrcturi, of the I'rovinee.10822 11X7-07 Le» Produits chimiques de Québec inc.Quebec Chemical Products Inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of April, 1007, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Dr.John Kane, chemist, Serge Caudreau, housewife, wife of the said John Kane, both of lido Ste-Foy Road.Custave Racine, chemist, and Rolande Dubé, housewife, wife of the said Custave Racine, the two latter of 340 des Peupliers West, all four of Quebec, for the following puriH)ses: The industry and business dealing in all kinds of chemical products, under the name of \"Les Produits chimiques de Quél>ce inc.\u2014Quebec Chemical Products Inc.\".with a total capital stock of $10,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head ollice of the company is at 250 Lee St., Quebec, judicial district of Quebec.Raymond Doi-villk, Assistant Secretari, of the Province.19822 1612-67 Les Produits laitiers Intcrprovinciatix ltéc Interprovincial Milk Products Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi îles compagnies, l'administrateur \u2022 lu gouvernement «le la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 12e jour «l'avril 1967, constituant en corporation: Lucien Mont-til-.comptable agréé, 194, rue Dulferin.Cécile Bernard, 382, rue St-Viateur, Joeelyne Lacoste, 113, rue Clarence, toutes deux secrétaires, filles majeures, et Yves Lagacé, avocat.12Ô, rue Fdgin, tous «pialre de Cranby, pour les objets suivants: Paire le commerce «le tous produits laitiers et de leurs SOUS-produits et faire affaires comme épiciers, sous le nom «le « Les Produits laitiers Interprovinciaux ltée \u2014 Interprovincial Milk Products Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires «le $10 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 317, rue Racine, Cranby, district judiciaire de Bedford.Le Sous-secrétaire de la province, Raymond Doi;villk.19822-0 1020-07 Produits Ronald ltéc Avis est «humé qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies.l'administrateur «lu gouvernement de la province a accordé \u2022les lettres patentes, en date «lu 31e jour «le mais 1967, constituant en cori>oration: Maurice Martel, avocat et conseil en Loi de la reine, 1301, St-\\'iateur ouest, Outremont, Lucille Roy, secrétaire, épouse de Jean-Claude Riais, 24, rue '\u2022Mies, Sainte-Thérèse-Ouest, et Fernande Perreault, secrétaire, fille majeure, 2825, boulevard St-Joseph-est, Montréal, pour les objets suivants: Les Produits laitiers Interprovinciaux liée Interprovincial Milk Products Ltd.Notice is given that umler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «late the 12th day of April, 1007, have been issued by the Administrator of the Government of the Province, incorporating: Lucien Montfils, cliart-ered accountant, 194 DufFerin St., Cécile Bernard, 382 St-Viateur St., Joeelyne Lacoste, 113 Clarence St., lioth secretaries, spinsters of the full age of majority, and Yves Lagacé, a«lvocate, 125 Flgin St., all four of Cranby, for the following purposes: To carry on business «lealing in all dairy products and in thou by-products, an«l to act as grocers, under the name of \"Les Produits laitiers Interprovinciaux ltée \u2014 Interprovincial Milk Products Lt«L\", with a total capital stock of $40,000, divi«le
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.