Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1968-06-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" kzette officie/le de Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 15 juin 1968 Règlements 1\" Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyer dans une seule langue la traduction en e»t faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Feyer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième in>ntion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droit ~ de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée (Ml |||US.5\" L'alwnncmcnt, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.ti° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7\" La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de cliaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus.l'Imprimeur de l.i reine a le droit de retarder la publication de d i tains documents, à cause de leur longueur ou |»iur des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.0° Si une erreur typographique se glisse dans \u2022nie première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, June 15, 1968 Rules 1.Address all communications to the Queen's Printer, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will lie automatically cancelled without prejudice to the Queen's Printer, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach the Queen's Printer not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, the Queen's Printer reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Queen's Printer before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Pibuee par le Gouvernement de la Province / Published bt the Provincial Government L'Imprimeur de la reine, roch lefebvre, Queen'i Printer \u2014 Québec 3224 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 16 juin 1968, 100' année, n° 2k Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les agnies, le lieutenant-gouverneur our les objets suivants: Manufacturer de la machinerie, îles moteurs, outils, instruments et articles de quincaillerie de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Acadian Precision Machining Inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et 3.000 actions privilégiées de $10 cliacunc.Le siège social de la compagnie est 126.Ronald Drive.Montréal-ouest, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.24945 1948-68 Adams Motel Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première l>artie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de décembre 1967, constituant en corporation: Frank James Adams, homme d'affaires, Allan James Adams, professeur, et Eileen Ann Adams, professeur, célibataire, tous trois de Saint-Majorique, pour les objets suivants: Letters Patent Acadian Precision Machining Inc.Notice is given that under Part I of the Com|>anies Act, letters patent, liearing dale iIk' 1st day of May.1968.have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gabor Vermes, 2009 Mansfield, Apt .\">!.Kalinan Pahoesa.8495 L'Acadie.Apt.603.IhiIIi businessmen, and Barnabas Vizkelety, advocate, 4426 Circle Road, all three of Montréal, for the following purposes: To manufacture and deal in machinery, engines, tools, implements and liardwarc of all kinds, under the name of \"Acadian Precision Machining Inc.\", with a total capital Stock of $40.000, divided into 1.000 common shares ol *10 each and 3.000 preferred sliares of $10 each.The head office of the company is at 126 Ronald Drive, Montréal West, judicial district of Montréal.Raymond Douvili.k, Assistant Secretary of the I'rorin, ».24945-0 liMS-iS Adams Motel Inc.Notice is given tliat under Part I of tlic Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of December, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Frank James Adams, businessman, Allan James Adams, professor, and Eileen Ann Adams, professor, spinster, all three of Saint-Majorique, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.Si 3225 bViiir, construire et ériger dans la ville de Gaspé, des motels et des constructions hôtellièrcs, sou- la nom de « Adams Motel Inc.», avec un egpital total de $200.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 cliacune.Le siège social de la compagnie est à Gaspé, district judiciaire de Gaspé.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 5181-67 Albert Preventive Maintenance Inc.Ai is est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, Constituant en corporation: Réjean-O.Albert, mécanicien et administrateur, 5797, rue Dubreuil, Saint-l48 Esplanade, all three of Montréal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Avy's Hot Dogs Ltd.\", with a total capital stock of $40.(KX), divided into 2.00(1 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 11hi7-68 II.K.B.limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: All)ert Bcauchamp, trucker.8511 rW IX, Angus Kenny, garage-keeper, 10542 Bruxelles both of Montreal-North, and Henri Brady, mechanic Côte Georges, Saint-Henri-de-Mas-couche (Mascouche), for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of metals, as well as in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"B.K.B.limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Mont-réal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1591-68 Bacchus Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of April, 1968, have been issued by the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 16, 1968, Vol.100, No.2k 3229 patentes, en date du 25e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Evangelos Valsamis, Jean A|»stolopoulos, tous deux de 2070, avenue I'liiim, et Alex Dimitropoulos, 844, avenue Ball, lou> trois restaurateurs, de Montreal, pour les object suivants: Kvploilcr un restaurant, sous le nom de ¦ Bacchus.Restaurant Inc.», avec un capital total île $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvtlle.24045 1906-68 Berman Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Donald Berman, administrateur, 1455, ouest, rue Sherbrooke, app.>.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred sliares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1951-OS Lc Festival de Stc-Agathe inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1908.have been issued by 11 Lieutenant-Governor of the Province to incorporate u corporation without share capital: Marcel Frenette, chartered accountant, Edmour Gauthier, electrician.Ghyslain Lapointe, notary.Isabelle Hamcl, housewife, wife separate as to property of said Ghyslain Lapointe, Guy Roy. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, Xo.gi 3235 Thomas Cloutier, industriel, Dolores Trudcll, secretaire, fille majeure, Pierre II,nm I.agent d'assurances.Louise Parent, ménagère, é|>ousc Répares de biens dudit Pierre Hamel, el Micheline J'aicinent.secrétaire, éjwuse séparée de biens o-rating: Maxwell Shenker, 1110 Sherbrooke West, Daniel Lazare, 4590 Michel Bibaud, both of Montréal, Mux M.Teitclbaum, 2365 Stevens Street, and Samuel II.Shriar, 2445 Valadc Street, the latter two of Saint-Laurent, all four advocates, for the following purposes: To operate garages and to deal in all kinds of automobile accessories and parts, under the name of \"(î & L Auto Parts (Laval) Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 500 class \"A\" sliares of a par value of $10 each, 500 class B shares of a j>ar value of $10 each and 9,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Provint;-.24945-0 1973-68 Gingras & Parisien inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>caring date the Tlh day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Gingras, Roland Parisien, bota mechanics, and Germain Raichc, clcrk-accoun-taut, all three of Thurso, for the following pur|>o.ses: To deal in automobiles, trucks, tractors, motors, planes, plane motors, motor boats, radios, frigidaires and other electric or electronic appliances, under the name of \"Gingras & Parisien inc.\".with a total capital stock of $4.010, divided into 401 common shares of $10 each.The head office of the company is ot 331 Victoria Street, Thurso, judicial districtof Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province, 24945 2020-08 Hôpital St-Louis dc Cowansville inc.Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du I7e jour d'avril 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Paul-Eugène Roy, médecin, Gérard Turmel, avocat, tous deux de Cowansville, et Yvon Daiglc, administrateur, West-Brome, pour les objets suivants: Établir, maintenir, organiser, agrandir, développer et administrer un hôpital pour personnes convalescentes ou atteintes de maladies chroniques, sous le nom dc « Hôpital St-Louis de Cowansville inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $500,000.Le siège social dc la corporation est à Cowansville, district judiciaire de Bedford.Le sous-secrétaire dc la province, Raymond Douville.24945-0 1164-68 Hôpital St-Louis dc Cowansville inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul-Eugène Roy, physician, Gérard Turmel, advocate, both of Cowansville, and Yvon Daiglc, administrator, West-Brome, for the following purposes: To establish, maintain, organize, enlarge, develop and manage a hospital for convalescents or people with chronic illnesses, under the name of \"Hôpital St-Louis dc Cowansville inc.\".The amount to wliich immovables that the corporation may acquire and own is to be limited to $500,000.The head office of the company is at Cowansville, judicial district of Bedford.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1164-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 196S, Vol.100, No.84 3237 Immeubles Al-Ger limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Marthe Beaudet, ménagère, épouse de Fernand Beaudet, 169, Gladstone, Alice Rouleau, ménagère, épouse de Henri Rouleau, 172, Gladstone, et Pierre Parisien, comptable, 21, rue James, tous trois d'Ottawa, province d'Ontario, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, sous le nom de « Immeubles Al-Ger limitée », aw, un capital total de $40,000, divisé en 40,000 ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Wakefield, partie Est, district judiciaire de Hull.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24915-0 1536-68 Industrial Stampings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mars 1968, autorisant la fusion des compagnies « Industrial Stampings Limited » et « McMarjo Manufacturer.Limited », toutes deux constituées en corporations en vertu dc ladite première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes datées, respectivement, «lu 20 février 1942 et du 28 février 1968, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce du fer, de l'acier et d'autres métaux, avec un capital total de $250,000, divisé en 300 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et en 22,000 actions privilégiées d'une valeur au pair «le $10 chacune.Le nom de la nouvelle compagnie est « Indus-trial Stampings Inc.».Le siège social de la compagnie est a Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-secrélaire de la province, Raymond Douville.24913 1188-68\u2014 1420/58 In ter-Restaurant Management Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de mars 1968, constituant en corporation: Norman N.Genser, avocat et conseil en Loi de la reine, 1545, rue McGregor, Peter Wagner, gérant, 2460, Benny Crescent, app.323, Aurora Picard, secrétaire, fille majeure, 2255, St.Matthew, app.707, tous trois de Montréal, et Wolfe M.Friedman, avocat, 5750, avenue Smart, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Faire le commerce de restaurateurs, sous le nom de «Inter-Restaurant Management Corp.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 38 actions privilégiées d'une valeur an pair de $1,000 chacune.Lesiège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1417-68 Immeubles Al-Ger limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marthe Beaudet, housewife, wife of Fernand Beaudet, 169 Gladstone, Alice Rouleau, housewife, wife of Henri Rouleau, 172 Glasdtone, and Pierre Parisien, accountant, 21 James Street, all three of Ottawa, Province of Ontario, for the following purposes: To carry on business as a real estate company, under the name of \"Immeubles Al-Ger limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common sliares of $1 each.The head office of the company is at Wakefield, Eastern Part, judicial district of Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1536-68 Industrial Stampings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, authorizing the amalgamation of \"Industrial Stampings Limite«l\" ont! \"McMarjo Manufacturers Limited\", both incorporated under the said Part I of the Companies Act, by letters patent dated, respectively, February 20, 1942, and February 28, 1968, for the following purposes: To manufacture and deal in iron and steel and all other metals, with a total capital stock of $250,000, divided into 300 common sliares of the par value of $100 each and 22,000 preferred sliares of the pur value of $10 each.The name of the new company is \"Industrial Stampings Inc.\".The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of St.François.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1188-68 \u2014 1420/58 Inter-Restaurant Management Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of March, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Norman N.Genser, advocate and Queen's Counsel, 1545 McGregor Street, Peter Wagner, manager, 2460 Benny Crescent, Apt.323, Aurora Picard, secretary, fille majeure, 2255 St.Matthew, Apt.707, all three of Montreal, and Wolfe M.Friedman, advocate, 5750 Smart Avenue, Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Inter-Restaurant Management Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a par value of $1 each and 38 preferred shares of a par value of $1,000 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1417-68 323s GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 19G8, 100' année, n° 2k Alex Jarjour inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province u accordé des lettres patentes, en date du 30c jour d'avril 1908, constituant en corporation: Alexandre Jarjour, commerçant, 79, Bryant, Y von Genest, avocat, 825, Huck, et Rosario (irenier, comptable, 580, Pelletier, tous trois de Sherbrooke, pour les objets suivants: Exploiter des magasins, ateliers et boutiques, sous le nom dc « Alex Jarjour inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc 810 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24915-0 1233-0S Alex Jarjour inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incur-Iiorating: Alexandre Jarjour, trader, 79 Bryant, Y von Gencst, advocate, 825 Buck, and Rosirio (irenier, accountant, 580 Pelletier, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To operate stores, shops and boutiques, under the name of \"Alex Jarjour inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and into 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head ollice of the company is at Sherbrooke, judicial district of St.François.Raymond Douvii.i.i., Assistant Secretary of the Province.24945 123348 La Jeune Chambre d'Amqui inc.Avis est donné qu'en vertu de lu troisième partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1908.constituant en corporation sans capital-actions: Gilbert Gauthier, professeur, Gilbert Fiset, agent d'assurances, et Claude Pcrreault.commerçant, tous trois d'Amqui, pour les objets suivants: Agir dans l'intérêt et |xiur l'avancement de la ville d'Amqui et plus particulièrement uu bénéfice des jeunes en les intéressant au progrès économique, social et civique de leur milieu, sous le nom dc « La Jeune Chambre d'Amqui inc.Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers nue peut acquérir et posséder la corporation, est de $10.000.Le siège social de la corporation est à Amqui, district judiciaire de Hiniouski.Le sous-sccrvtaire de la prorince, Raymond Douville.24945-0 1946-08 Jeune Chambre de Prince» ille inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieiitcnant-gouverneur de la province a accordé îles lettres patentes, en date du 6é jour de mai 1908.constituant en corporation sans capital-actions: Jean Moisan, 55, rue Laurier, Arlliuhaska.Jules Bclluvuncc.1810.St-Calixte, Plessisvillc.tous deux avocats, et Claire Houde.secrétaire, épouse séparée de biens d'André Lccomtc, 5B, rue Robitaille, app.2, Yictoriavillc, pour les objets suivants: Promouvoir l'intérêt des membres en rapport avec les affaires municipales, provinciales et fédérales, et plus particulièrement donner à ceux-ci l'initiation au monde des affaires, sous le nom de « Jeune Chambre de Princeville inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $50.000.Le siège social «le la corporation est a Prince-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-secrétaire dc la prorince, Raymond Douville.24945-0 2016-68 La Jeune Chambre d'Amqui inc.Notice is given tliat under Part III of the Companies Act.letters patent.Iiearing dale the 30th day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a rjoipoiatipn without share capital: Gilbert Gauthier, teacher.Gilbert Fiset.insurance agent, and Claude Perreault, trader, nil three of Ainqui, for the following purposes: To promote the interest and progress of the town of Ainqui and.more particularly, to stimulate the interest of young people in tlie economic, social and civic promotion of their environment under the name of \"La Jeune Chambre d'Amqui inc.\".The amount to which is limited the annual revenue on the immovable property which the Corporation may acquire ami own is of 80'.1100.The head ollice of the corjioration is al Ainqui.judicial district of Rimouski.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.24945 104648 Jeune Chambre de Prince» ille inc.Notice is given tliat under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 6th (lay of May, 1968, nave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital.Jean Moisin, 55 Laurier St., Arthabaska.Jules Bcllavancc.1810 St-Calixte.Plessisvillc.both advocates, and Claire Hondo, secretary, uifc separate as to property of André Ix-comtc.,VB Robitaille Street, Apt 2, Yictoriaville, for the following purposes: To promote the members' interest in municipal provincial and federal affairs, and particularly to give them initiation into the world of business, under the name of \"Jeune Chambre de Prince-ville inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to Ik- limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Prince-ville, judicial district of Arthabaska.Raymond Douville.Assistant Secretary of the 1'roriiice.24945 2010-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.2k \\a Jeune Chambre de Sutton Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie île la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1908, constituant en corporation sans capital-actions: ïvon l'uqiietto.menuisier.Félix Bédard.mécanicien, André Camille, commis, et Robert Boulanger, industriel, tous quatre de Suttou, pour le.objets suivants: Agir dans l'intérêt et pour l'avancement de la villi' de Sutton et plus particulièrement au bénéfice des jeunes en les intéressant au progrès économique, social et civique de leur milieu, sous le nom de « La Jeune Chambre de Sutton ».I.e montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de S500.000.I.e siège social de la eor|x)ration est à Sutton, district judiciaire de Bedford.Le som-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 1832-68 Joly-Sae Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnant-CDU vcmeur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 30c jour d'avril 1968, constituant en corporation: Jean Ix-clerc.pompier.Lise Bourgeois, ménagère, épouse contruc-tiicllcmciit m-parëc de biens dudit Jean Lcclerc, tous deux de 440.July, et Jeun-Paul Boyer, comptable.5, place Navarre, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Fabriquer des contenants, Inities, sacs, et tous autres articles ou produits .semblables, sous le iiaiii de « Joly-Sac Inc.», avec un capital total dc $4.000, divi>c en 400 actions ordinaires «le $10 cliacune.Le siège sagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire dc la province, Raymond Douville.KMIÎ 1713-68 C.Jul ru- inc.Avis est donné «m'en vertu dc la première partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant ¦ gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en «late du 6e jour de mai 1968, constituant en corporation: Pierre Jutras, Pierre Oeuaiilt, tous deux avocats, dc 117, rue Notre-Dame est.et (ieorges-Êtiennc Jutras, fonctionnaire, 737, rue Notre-Dame ouest, tous trois de \\ ICtoriaville, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de e G.Jutras inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 cliacune et en 3,000 action- privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1574, chemin St-Louis, Sillery, district judiciaire de Québec, Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 2042-68 Koban Cosmetics Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première Partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres La Jeune Chambre de Sutton Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th (lay of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Y von Paquettc, joiner.Félix Hédard, mechanic, André Camille, clerk, and Rolicrt Boulanger, industrialist, all four of Sutton, for the following purposes: To act in the interest and for tlie promotion of the town of Sutton and.more particularly, to help the young people by developing their interest in the economic, social and civic progress of their environment, under the name of \"La Jeune Chambre de Sutton\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and own is of $500.000.The head office of the corporation is at Sutton, judicial district of Bedford.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1832-68 Joly-Sac Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent.Ix-aring date the 80th day of April.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Leclcrc.fireman.Lise Bourgeois, housewife, wife contractually separate as to property of the said Jean Leclerc, both of 440 Joly.and Jean-Paul Boyer, accountant, 5 Place Navarre, all three of Laval, for the following purposes: To manufacture and deal in containers, boxes, bags anil all similar items or products, under the name of \"Joly-Sac Inc.\", with a total capital stock of $4,000, divided into 400 common sliares of $10 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24045-o 1713-68 G.Jutras inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Jutras, Pierre Denault both advocates, of 117 Notre-Dame St.East, and Georges-Etienne Jutras, civil servant, 737 Notre-Dame St.West, all three of Victoriaville, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"G.Jutras inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $10 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 1574 St.Louis Road, Sillery, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 2042-68 Koban Cosmetics Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of April, 1968, have been issued 3240 CAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 15 juin 1908.100' année, »° 81 [latentes, en date du 24e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Rowland A.Thomas, chimiste, Alice M.Thomas, agent d'information, 3' «use dudit Rowland A.Thomas, et Marcus J.ollander, étudiant, tous trois de 1120, ouest, rue Bernard, app.6, Outremont, pour les objets suivants: La fabrication et la vente de médicaments brevetés et/ou spécialités médicales, préparations pharmaceutiques et médicales et cosmétiques ou produits de beauté, sous le nom de * Koban Cosmetics LUI.», avec un capital-actions dc $10,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune.I.e siège social dc la compagnie est 1120, ouest, rue Bernard, app.6, Outremont, district judiciaire de Montréal.Le sous-seerftaire de la province, Raymond I)ouvii.lk.24945 1755-68 Lamarre transport 67 inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de juin 1907.constituant en cor|>oration: Gérard Corbcil.avocat, 394, de Maricourt.Longucuil, Claire Mallette, secrétaire, fille majeure, 2785.Beaujolais.Saint-Michcl-dcs-Sainls, Aurcy Desmarchais.271.Jacques-Cartier, et .Jean-Guy Desmarchais, 271A, Jacques-Cartier, ers deux derniers camionneurs, de Saint-Jean, |h>ur les objets suivants: Faire du transport général, sous le nom de « Lamarre transport 07 inc.».avec un capital total de $40.000.divisé' en 4.000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est A Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Le sous-iecrftaire de la prorince, Raymond Dor vii.i.k.24945-0 2578-67 Marché A.G.L.inc.A.G.L.Supermarket Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première liarlie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province u accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'avril 1908.constituant en cor|k>rution: Antonio Lomhurdi.mécanicien.Rusa Iacampo.ménagère, épouse dudit Antonio Lomhurdi.tous deux de 67.Sherwood.Chftteauguay, Guido Lomhurdi.imprimeur, et < 'arolina Iacampo.ménagère, é|Kiu.se dudit Guido Lomhardi, ces deux derniers de 5231, rue Mont-clair, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers-boucliers, sous le nom «le « Marché A.G.L.inc.\u2014 A.G.L.Supermarket Inc.».avec un capital total de $40.000.divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 3, rue La-joie, Chuteauguay-Ccntrc, district judiciaire de Bcauharnois.Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Dor vii.i.k.24945-0 1537-68 Martinique Sportswear Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour d'avril 1968, constituant en corporation: W.Robert Golf man.by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rowland A.Thomas, chemist, Alice M.Thomas, mediu director, wife of the said.Rowland A.Thomas, and Marcus J.Hollander, student, all three of 1120 Bernard Street \\\\( i, Apt.6, Outremont for the following purposes: To carry on the manufacture and sale of patent and/or proprietary medicines and medical an.I pharmaceutical preparations and cosmetic- or beauty products, under the name of \"Koban Cosmetics Ltd.\", with a total capital stock of $10,000, divided into 1,000 common shares of $10 each.The head ollice of the company is at 1120 Bernard Street West, Apt.6, Outreuiont, judicial district of Montréal.Raymond Doivii.i.k, Assistant Secretary of the I'rovinre.24945-0 1755-65 I amane transport 67 inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing dale i lie 8th day of June.1907.have lieen issued by i be Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Corlicil.advocate, 394 dc Maricourt.Longucuil.Claire Mallette, secretary, spinster of the full uge of nuijorily.2785 Beaujolais.Saint-Michel-dcs-Saints, Aurcy Désunir-ehuis.271 Jacques-Cartier, and Jean-Guy lie-marchais.27IA Jacques-Curlier, the latter two truckers of Saint-Jean, for the following purposes: To deal in general transportation, under I he name of \"Lamarre transport 07 inc.\".with u total capital stock of 140,000, divided into 4.IHK) common shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Jean, judicial district of Iberville.Raymond Dot vii.i.k.Assistant Secretary of the Protince.24945 2578-07 Marché A.G.L.inc.A.G.L.Supermarket hie.Notice is given tliut under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing dale the 4th day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-corporal ii ig Antonio Lomhardi.mechanic.Ron Iacampo.housewife, wife of the said Antonio Lomhardi.both of 07 Sherwood.Chateaugiiay.Guido Lomhardi, printer, and Carolina Iacampo.housewife, wife of the said Guido Lombardi, the latter two of 5231 Montclair street.Montréal, for the following purposes! To carry on business as grocers-butchers, under the name of \"Marché A.G.L.inc.- A.G.L.Supermarket Inc.\", with u total capital stuck of $40.000.divided into 2.000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 3 La joie street, Cluiteauguay-Centrc, judicial district of Beauharnois.Raymond Doi'villk.Assistant Secretary of the Province.1537-08 24945 Martinique Sportswear Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of April, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: W.Robert Golfman, 3475 Duro- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.3A 3241 347\").Duroclier, Joseph Tarasofsky, 4572, Cool-brook, tous deux de Montréal, et Jack Sliayne, 5781.Moiling, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Confectionner des vêtements et tous accessoires s'y rattachant, en faire le commerce, sous le nom de « Martinique Sportswear Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 Cliacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1875-68 Matte Électronique inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Roland Matte, industriel.Madeleine Luplante.ménagère, é|>ouse séparée île biens dudit Roland Mutte, tous deux de 147, 04e rue est, Charlesbourg, et Sylvio LcBlanc, comptable agréé.2965, Ire avenue, Québec, |>our les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de toutes sorte- d'appareils électroniques ou électriques, sous le nom de « Matte Électronique inc.», avec un capital total dc $40.000.divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 147.64e rue est, Charlesbourg, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-0 1378-68 Mcldev Company Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Irving Shapiro, avocat, 4957, Isabella, ElayneP.Felix, secrétaire, célibataire d'âge majeur, 2030, Henri-Bourassa, app.'.'\").tous deux dc Montréal, et Mark Edmund Gordon, avocat, 36, avenue Roxborough, West-mount, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de terrains, construction et améliorations, sous le nom de < Meldev Company Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1960-68 La Mercerie d'Amqui Itée Avis est donné qu'en vertu de la première Partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Gilbert Fiset, courtier en assurances, Causapscal, Florent Proulx, «munis, Rimouski, et Raymond Viens, marchand, Amqui, pour les objets suivants: cher, Joseph Tarasofsky, 4572 Coolbrook, both of Montréal, and Jack Shayne, 5781 Melling, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and all accessories thereto, under the name of \"Martinique Sportswear Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each and 39,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1875-68 Matte Électronique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Matte, industrialist, Madeleine Laplante.housewife, wife separate as to property of the said Roland Matte, both of 147, 64th Street East, Charlesbourg, and Sylvio LeBlanc, chartered accountant, 2965, 1st Avenue, Québec, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of electronic or electrical equipment, under the name of \"Matte Électronique inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 3,000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 147, 64th Street East, Charlesbourg, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1378-68 Mcldev Company Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving Shapiro, advocate, 4957 Isabella, Elayne P.Felix, secretary, spinster of the full age of majority, 2030 Henri-Bourassa, Apt.25, both of Montréal, and Mark Edmund Gordon, advocate, 30 Roxborough Avenue, Westmount, for the following purposes: To carry on the business of a land, construction and improvement company, under the name of \"Meldev Company Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 commons shares of the par value of $1 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1960-68 La Mercerie d'Amqui Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilbert Fiset, insurance broker, Causapscal, Florent Proulx, clerk, Rimouski, and Raymond Viens, trader, Amqui, for the following purposes: 3242 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1908, 100' année, n\" 21 Faire le commerce de vêlements de toutes sortes, sous le nom dc « La Mercerie d'Amqui Itée », avec un capital total de $50,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Amqui, district judiciaire de Rimouski.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Dolvii.i.k.24945-o 1937-08 Molo Enterprises lue.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Moc Ackman, 8128, 3e avenue, Laval.Irwin (iliserman, 5719, Rrookside, Edward J.Druker, 5703.McMurruy, tous deux de Côte Saint-Luc.et Jack Roidmaii, 5320, MacDonald.Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Tenir hôtel, motel, taverne, auberge, restaurant ou toute combinaison d'iccux, sous le nom de « Molo Enterprises Inc.», avec un capital total de 840.000.divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de lu compagnie est '2280, boulevard Beaudet, Sainl-Luurcut, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province.Raymond Dor vii.i.k.24945 1972-68 Montreal .Maritime Inc.Avis est donne qu'en vertu de lu première partie de lu Ixii des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation : Henri-Paul Lemay, 420.Chumpugueiir.Oiitremont, Maurice Puquiu, 3023, chemin St-Louis, Saintc-Foy, tous deux avocats et conseils en Loi de lu reine, Micheline Corbeil, fille majeure, 2540, chemin Côte Ste-Catherine, Montréal, et Michel Gilbert, 100, avenue du Palais, Saint-Joscph-dc-Bcauce, ces deux derniers avocats.|>our les objets suivants: Exploiter une compagnie de navigation, sous le nom dc « Montreal Maritime Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 3,900 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Donvii.i.k.24945-0 1923-68 Nettoyeur Riviera inc.Riviera Cleaner Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1908, constituant en corporation: Ernest Manzo.commis, Lucille Joly.ménagère, épouse séparée de biens dudit Ernest Manzo, tous deux dc 8341, Casgrain, Yves Allaire, nettoyeur, et Claudette Bélanger, ménagère, épouse séjiarée de biens dudit Yves Allaire, ces deux derniers dc 1684, Camille-Paquette, tous quatre de Montréal, |»ur les objets suivants: To deal in clothing of all kinds, under the name of \"La Mercerie d'Amqui Itée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 28) common shares of $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Ainqui, judicial district of Rimouski.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province, 24945 193748 Molo Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 190S, have been i-siiod by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Moc Ackman, 3128, 3rd Avenue, Laval.Irwin (iliserman, 5719 Rrookside, Edward J.Druker, 5703 McMurroy, both of Côte Saint-Luc und Jack Boidman, 5320 MacDonald, Montréal, all four advocates, for the following pur-poses: To carry on the business of hotel, motel, tavern, public house, restaurant or any combination thereof, under the name of \"Molo Enterprise* Inc.\", with a total capital stock of $4(1.(100, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is ut 22M) Beaudet llotilcvard, Saint-Laurent, judicial district of Montréal.Raymond Dor villi:.Assistant Secretary of the Produce.24045-o 1872 68 Montreal Maritime Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing dale the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri-Paul Lemay.420 Champs-gneur.Oiitremont, Maurice Paqiiin.3023 St-Ixiuis Road.Sainte-Foy, both advocates ami Queen's Counsel, Micheline Corhcil.spin-tcr of the full age of majority, 2540 Côte Ste-Callic-rine Road, Slonlréal, and Michel Gilbert, WO du Palais Avenue, Saiiit-Joseph-dc-Reaiiee.the latter two advocates, for the following purposes: To operâté a shipping company, under I lie name ot \"Montreal Maritime Inc.', with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 3,900 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretan/ of the Province.24945 1923-68 Nettoyeur Riviera inc.Riviera Cleaner Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ernest Manzo, clerk, Lucille Job, housewife, wife separate as to property of saul Ernest Manzo.both of 8341 Casgrain.It* Allaire, cleaner, and Claudette Bélanger, housewife, wife separate as to property of said N ves Allaire, the latter two of 1684 Camille-Paquctte, all four of Montréal, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.2k 3243 Poire affaires comme nettoyeurs, presseurs, teinturiers, buandiers, et faire la réparation de vêtements, tissus, marchandises et ameublements de maison, sous le nom de « Nettoyeur Riviera inc.Riviera Cleaner Inc.».avec un capital total de S40.000.divisé en 2.000 actions ordinaires de 310 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville._M!> l.V.» 1020-08 To carry on business as cleaners, pressors, dyers, laundcrers, and to repair clothing, woven material, merchandise and house furniture, under the name of \"Nettoyeur Riviera inc.\u2014 Riviera Cleaner Inc.\" with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1620-08 Paramount Automobile Montreal Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de In Loi des compagnies, le lieutcnant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour «l'avril 1908, constituant C corporation: l'aul l.i-gaull.marchand.Juliette Villeneuve, ménagère, épouse séparée de biens dudit l'aul Legault.et Rhéal Lcgault, commerçant, tous trois de 5535.Men-nercuil.Saint-Léonard.|>our les objets suivants: Exploiter «les stations-service, garages et faire le commerce de camions, tracteurs, automobiles et véhicules de toutes sortes, sous le nom île « Paramount Automobile Montreal Inc.avec un capital total de $40,000.divisé en l.lllltt actions ordinaires de $10 chacune et en HIHI actions privilégiées de $100 chacune.I.e siège social de la compagnie est 9050, rue Lijeinic-.se, Montréal, district judiciaire de Montreal.I.e sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2194541 1738-68 Pétroles Orford inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies, le lieutcnant-goiivcrneur île la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 1908, constituait eu corporation : Jacques Rergeron, Jeau-Claude Hergeron, tous deux journaliers, dc route rurale numéro 2, et Gérard Cayer.commerçant, 4\", Si-Jacqucs, tous trois de Magog, pour les objets suivants: l'aire le commerce de différentes sortes d'huile de chauffage ou autres, gaz naturel, pétrole, sous le nom de » Pétroles Orford inc.\"', avec un capital total île $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de S 1(H) chacune Le siège social de la compagnie est à Magog, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24915-u 1945-68 Alfred Pettinicchi, Stone, Sand & Gravel Inc.Alfred Pettinicchi, pierre, sable & gravier inc.Avis est.donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1968, eoiist iluant en corporation: Robert Lefcort, 5025, Ma.Donald, Leonard YV.Flanz, 4680, rue Bourret, et Yoine Goldstein, 4530, Côte des Neiges, tous trois avocats, de Montréal, pour es objets suivants: La fabrication, traitement, distribution et Wnte de matériaux de construction de toutes sortes, y compris pierre concassée, sable et gra- Paramount Automobile Montreal Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 23rd day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Legault, merchant, Juliette Villeneuve, housewife, wife separate as to pro-perty of the said Paul Legault, and Rhéal Legault, trailer, all three of 5535 Mcnnereuil, Saint-Léonard, for the following purposes: To operate service stations, garages and to deal in trucks, tractors, automobiles and all kinds of vehicles, under the name of \"Paramount Automobile Montreal Inc.\".with a total capital slock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred sliares of $100 each.The head office of the company is at 9950 Lajeunesse street.Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1738-68 Pétroles Orford inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Bergeron.Jean-Claude Bergeron, both labourers, of Rural Route Number 2, and Gérard Cayer, trader, 47 Saint-Jacques, all three of Magog, for the following purposes: To deal in different kinds of fuel oil, natural gas, petroleum, under the name of \"Pétroles Orford inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Magog, judicial district of St.François.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1945-68 Alfred Pettinicchi, Stone, Sand & Gravel Inc.Alfred Pettinicchi, pierre, sable ceii issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray Lapin, advocate and Queen's Counsel.107 Kdgehill Road.Westmount, Norman May, 55 Holt ham Road, Hempstead, and Avrum Rubinger, 4530 Côte des Neiges, Montréal, the latter two advocates, for I he following purposes: To operate restaurant, public house, tavern, hotel or any combination thereof, under the name of \"Polynesian \u2014 Chinese Restaurant - \"I Montreal Inc.\u2014 Les Restaurants Polynésiens Chinois de Montréal inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 10.000 common shares of the par value of $1 each and 3.'100 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretary of the Province 24945-0 1924-08 Pomerleau & Thérien inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Albert Thérien, contractor, 5355 De Gaule Ave., Claude Thérien, comptroller, 162, 47th St.West, both of Charlesbourg, and Laurent Thérien, foreman, 3425 Royale, Giffard, for tlie following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1908, Vol.100.No.21 3245 l'aire affaires comme entrepreneurs généraux en travaux de pavage et construction de toutes .sortes, sous le nom de « Pomerleau & Thérien inc.avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 cliacune.I.e siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire dc Quéliec.lie sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24045-o 2704-68 l'on lin & Mercier (1968) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur .', 3249 Le siège social de la compagnie est 1000, boulevard des Laurentides, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1976-68 Guy Sanschagrin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Guy Sanschagrin, constructeur, Mercedes Sanschagrin, ménagère, épouse séparée de biens dudit (îuy Sanschagrin, tous deux de 2120, Flcury est, et Jean de Grand-pré, compable agréé, 875, Fleury est, tous Irois île Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Guy Sanschagrin inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-q 1813-68 The head office of the company is at 1000 des Laurentides Boulevard, Laval, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1976-68 Guy Sanschagrin inc.Notice is given tlint under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of April, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Sanschagrin, constructor, Mercedes Sanschagrin, housewife, wife separate as to property of said Guy Sanscliagrin, both of 2120 Fleury East, and Jean de Grandpré, chartered accountant, 875 Fleury East, all three of Montréal, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building contractors and to deal in all kinds of material, under the name of \"Guy Sanschagrin inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1813-68 Société de Finance Mark V inc.Vyis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mai 19(58, constituant en corporation: Raymond Crcvier, 70, avenue Vivian, Mont-Royal.Pierre Legrand, 14.15.Cap Eternité.Laval, et Jean-A.Savard, 4351, Draper, Montréal tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de finance sous tous ses aspects, sous le nom de « Société dc Finance Mark V inc.».avec un capital total de $1110.000.divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2l!l45-o 1988-68 Société de Finance Mark V inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters |>atent.bearing date the 1st day of May, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Raymond Crevier, 70 Vivian Avenue.Mount Royal, Pierre Legrand, 1435 Cap Éternité, Laval, and Jean-A.Savard, 4351 Draper, Montréal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a finance company in all its aspects, under the name of \"Société de Finance Mark V inc.\", with a total capital stock of $10U0O0.divided into 10.000 common shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1988-68 Société immobilière Habitat Itée Wis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mai 1908, Constituant en corporation: Jean-Louis Voisine, herald Fortin et Denis Maltais, tous trois commis, d'Ahna, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble el de construction, sous le nom de « Société immobilière Habitat Itée », avec un capital lolal de $40.000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.I/c siège social de la compagnie est à Aima, district judiciaire de Roberval.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-0 1984-68 Société immobilière Habitat Itée Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Louis Voisine, Gérald Fortin and Denis Maltais, all three clerks of Alma, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Société immobilière Habitat Itée\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Alma, judicial district of Roberval.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1984-68 3250 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1908, 100' année, n° ti Station Marcel Frechette inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 196S, constituant en corporation: Marcel Frechette, commerçant, Denise Demers, ménagère, épouse commune en biens dudit Marcel Frechette, et.dûment autorisée par lui aux fins des présentes, et Clément Frechette, constable, tous trois de Saint-Nicolas, pour les objets suivants! Exploiter un ou plusieurs garages, stations de service, établissements et entrepôts, sous le nom de «Station Marcel Frechette inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Nicolas, district judiciaire de Québec.Le êouesecrStaire de lu province, Raymond Dot -vii.i.k.24945-0 1376-68 Taverne Viau-Hochcluga inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie dc la Loi des compagnies-, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Robert-Basile Peides, iuqxirtatcur.Simone Beau, ménagère, épouse contractiicllcmcnt séparée de biens dudit Robert-Basile Peides, tous deux de 172, Brookfield, Mont-Royal, et (ïuy Saïd Mohammedi.constructeur.9311.15e avenue, Saint-Michel.|K>ur les objets suivants: Faire affaires comme taverniers, sous le nom île « Taverne Yiau-IIochclaga inc.», avec un capital total de $25,000, divisé en 250 actions ordinaires de $100 cliacune.Le siège social de la compagnie est 4209, rue Hochelaga, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le .tous-secrétaire île la province, Raymond Dor vii.i.k.24945-0 1086-68 Tcm-C.o Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première |Mirtie de la I»i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1908.constituant en corporation: Abraham Sinister.5710, Wolseley, Lawrence Glazer, 7920, Kingsey, tous deux de Cote Saint-Luc, Arthur .1.Marcovitch.110, ouest, ('remanie, tous trois avocats, et Meta Csirinyi, secrétaire.é|Miuse sé|Miréc de biens de .lulius Csirinyi.6940.Wiseman, ces deux derniers de Montréal, imur les objets suivants: Fabriquer toutes sortes de produits, articles et marchandises, en faire le commerce, sous le nom de « Tein-('o Enterprises Inc.», avec un capital total (le $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire Je la province, Raymond Douville.24945 1958-68 Time Data Control Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la prorince a accordé des lettres Station Marcel Frechette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incur.|k)rating: Marcel Frechette, trader, Denise Demers, housewife, wife common as to property of the said Marcel Frechette, ami duly authorized by him for these presents, and ( 'lenient Frechette, constable, all three of Saint-Nicolas, for the following purposes: To operate one or more garages, service stations, establishments and warehouses, under the name of \"Station Marcel Frechette inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 3.000 common shares of $10 each and 1.0110 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at Saint-Nicolas, judicial district of Québec.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.24945 1376-08 Taverne Yiau-llochclnga inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 190S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert-Basile Peides, importer, Simone Beau, housewife, wife contractually separate as to perperty of said Robert-Basile Peides, both of 472 Brookfield, Mount Royal, and Guy Said Mohammedi.constructor.9311, 15th Avenue.Saint-Michel, for the following purposes: To carry on business as tavern-keepers, under the name of \"Taverne Yiau-IIochelaL'a inc.\", with u total capital stock of $25.0011, divided into 250 common shares of $100 each.The head office of the company is at 1209 Hochelaga Street, Moiitréul.judicial district of Montréal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24945 168648 Tein-Co Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters (Mitent, bearing date the 29th day of April, 1908.luive lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Abraham Sinister, 5710 Wolseley.Lawrence Gliizer, 7920 Kingsley, both of Côte Saint-Luc, Arthur .I.Marcovitch.110 Crémazie Wc-I.all three advocates, and Meta Csirinyi.secretary, wife separate as to property of Julius Csirinyi, 0940 Wiseman, the latter two of Montréal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Tcm-Co Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of the |Nir value of $1 each and 3,500 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1958-6S Time Data Control Inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.2k 3251 patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Nguyen Van Duycn, ingénieur, Ruth Roy, professeur, épouse dudit Nguyen Van Duycn.tous deux dc 7400.Sherbrooke) ouest, et Jean I.enghnn, ingénieur, 8351, Clark, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer el faire le commerce de toutes Milles d'appareils électriques et électroniques, xiiis le nom de « Time Data Control Inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 400 actions ordinaires dc S25 chacune et en 1,200 actions privilégiées de $25 cliacune.Le siège social de la compagnie est 7400, rue Sherbrooke ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le tous-secrétaire de la province, Raymond Douville.241U5-0 1872-68 Union du Livre et des Arts Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 196S, constituant en corporation : Antoine (iougeon, administrateur de société, Théodore Isorni, André l.ei orre.tous deux libraires, tous trois de Le C'olisée, 235, Sherbrooke ouest, app.1104, Raymond Lette, avocat, 27, McNidier, el Lucienne lloilenmann, secrétaire, fille majeure, 3421, Hi iiininond, app.26, tous cinq de Montréal, pour les objets suivants: < 'oinmeree de livres, de reproduction d'arl, de disques, de moyens audio-visuels et de tous autres articles destinés n l'éducation, sous le nom de « Union du Livre et des Arts Itée », avec un capital total dc $40.000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-0 2033-08 Union Truck Sales Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres pal entes, en date du 3c jour de mai 1968, constituant en corporation: Michel Baillargeon, vendeur, Gérard Daviault, entrepreneur, tous deux de Saint-Lambert, et Gervaiso Hrisson, avocate, fille majeure, La Prairie, pour les objets suivants: l'aire le commerce dc camions, automobiles, machinerie et équipement de toutes sortes et posséder tout le matériel roulant nécessaire ù celte fin, sous le nom de « Union Truck Sales Inc.\\ avec un capital total de $90,000, divisé en 000 actions ordinaires dc $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 112, rue Union, Saint-Lambert, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24045-o 1512-68 Au Vieux Pont inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Nguyen Van Duyen, engineer, Ruth Roy, professor, wife of said Nguyen Van Duyen, lx>th of 7400 Sherbrooke West, and Jean Len-glian, engineer, 8351 Clark, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of electrical and electronic appliances, under the name of \"Time Data Control Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $25 each and into 1,200 preferred shares of $25 each.The head ollice of the company is at 7400 Sherbrooke Street West, Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1872-68 Union du Livre et des Arts Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antoine (iougeon, association administrator, Theodore Isorni, André LeCorre, Imtli book-sellers, all three of Le Colisée, 235 Sherbrooke west.Apt.1104, Raymond Lette, advocate, 27 McXider, and Lucienne Bodenmann, secretary, spinster of the full age of majority, 3421 Drummoiid, Apt.26, all five of Montréal, for the following purposes: To deal in books, art reproductions, records, audio-visual devices and in all other articles used in the field of education, under the name of \"Union du Livre et des Arts Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common sliares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 2033-68 Union Truck Sales Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Baillargeon, salesman, Gérard Daviault, contractor, both of Saint-Lambert, and Gcrvaise Brisson, advocate, spinster of the full age of majority, La Prairie, for the following purposes: To deal in trucks, automobiles, machinery and equipment of all kinds and to own all the rolling-stock necessary for this purpose, under the name of \"Union Truck Sales Inc.\", with a total capital stock of $90,000, divided into 600 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The bead office of the company is at 112 Union Street, Saint-Lambert, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1512-68 Au Vieux Pont inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, liearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in- 3252 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1908, 100' année, n' 2k constituant en corporation.) Camil Richard, épicier, Suzanne Richard, secrétaire, épouse séparée de hiens dudit i mini Ricliard.tous deux dc 8678, boulevard «les Milles Isles.Laval, et Denis Hédurd.évaluatcur.284, Grande Cote, Sainte-Thérèse.poW les objets suivants: Exploiter un ou des magasins généraux, sous le nom de « Au Vieux Pont inc.», avec un capital total de $40.000.divisé en 3,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 1.000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 0570, boulevard des Milles Isles.Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.24945-o 1899-08 corporatiug: Camil Hichard, grocer, Suzanne Ricliard.secretary, wife separate as to property of the said Camil Richard, l>oth of 6570 des Milles Iles Blvd.Laval, and Denis Bédanl.appraiser, 284 Grande Côte, Sainlc-Thér< -c, for the following purposes: To o|H'rate one or more general stores, under the name of \"Au Vieux Pont inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 3.000 common shares of $10 each and 1,000 preferred sliares of $10 each.The head office of the company is at 0570 del Milles Iles Blvd., Laval, judicial district of Montréal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Prorimr.24945 1899 68 Jos.C.Wray & Bro.(1968) Inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentee, en date du 29e jour «l'avril 1908, constituant en corporation: Krnest .lames La t timer, 10.avenue Rosemont.Joseph Seymour lilumer, 225.avenue Olivier, tous deux avocats, de Westmount, et Fleurunge Décurie, secrétaire, célibataire, 1710.rue Dorchester, Montréal.i>our les objets suivants: Exploiter, dans toutes ses s|>écialités.un Commerce il'entrepreneurs de pompes funèbres, sous le nom de « Jos.('.Wray \\ Bro.(1908) Inc.», avec un capital-actions divisé en 225.000 actions ordinaires salis valeur au paii.Ix' siège .social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-uccrétairc de la prorince.Raymond Douville, 24945 1455-08 Jos.C.Wray & Bro.(1968) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 29th day of April.1908.huve been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ernest James Lattimer.10 Rose-mount Avenue.Joseph Seymour Blunier.225 Olivier Avenue.Iwth advocates, of Westinounl.and Fleurunge Décarie, secretary, spinster.1711) Dorchester Street.Montréal, for the following purposes: To carry on in all its branches the business of funeral directors, umler the name «>f \"Jos.('.Wray & Bro.(1908) Inc.\".with a capital stock divided into 225,000 common shares without par value.The head ollice of the company is at Moulical.judicial district of Montréal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Produce.24945-0 14ô.\"i-(iS Wright Machine, Tool & Die Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 19e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Sylvia Evans, ménagère, épouse séparée «le biens de Roliert Wright, 194, Roy de Nord, Laval, John Anderson East-vchl, et Donald \\V, Eastvehl, ces deux derniers agents d'immeubles, «le 43, Eastbourne, Beacons-field, |k>ur les objets suivants: Manufacturer «le la mocluncric.des moteurs, outils, instruments et articles dc quincaillerie dc «le toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Wright Machine, Tool & Die Ltd.», avec un capital total de $55,000.divisé en 5,000 actions ordinaires «le $1 chacune et 50,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1499-68 Wright Machine, Tool & Die Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th (lay of April, 1908, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Sylvia Evans, housewife, wife separate as to property of Robert Wright, 194 Roy de North, Laval.John Anderson East veld, and Donald W.Eastvcld, the latter two real estate salesmen, of 43 Eastl>ourne, Beaeonsficld.tor the following purposes: To manufacture and deal in machinery, engines, tools, implements and hardware of all kinds, under the name of \"Wright Machine.Tool & Die Ltd.\", with a total capital stock of $55.000, divided into 5,000 common shares of $1 each and 50,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 1499-08 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Arfel Corporation Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1968.à la compagnie « Arfel Corpora- Arfel Corporation Notice is given tliat.under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent.Iiearing date the 24th day of April, 1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Arfel Corporation\", increasing the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.21 3253 timi ».augmentant la considération totale pour laquelle les actions ordinaires sans valeur au pair peuvent être émises de $100.000 à 8800,000.Le sous-secrétaire de la province, Kaymon'u Douville.24946*0 130-08 \u2014 1420/33 Café Sirtaki liée Avis est donné (|u'cn vertu i des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province u accordé des lettres patentes supplémentaires en dute du 25e jour d'avril 1968, à la compagnie « Roger Dcland inc., étendant ses pouvoirs.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvii.i.i:.24945^o 4468-65- 1419/67 Les Éditions J.-M.Doré inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l/ii des compagnies, le lieiiteiiunt-gouverneiir de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1908, à la compagnie « J.-M.Doré inc.-, constituée par lettres patentes en date du 25c jour de novembre 1903.échangeant son nom en celui de «Les Editions J.-M.Doré inc.»; 2° étendant ses pouvoirs./.c sous-scerftaire dc la prorince, Raymond Douvii.i.i:.24945-q 5050-63 1420/47 Roger Delund inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, liearing date the 25th day of April, I96S.have been issued by the Lieut cnunt-Govcriior of the Province to \"Roger Delaiul inc.\", extending iu powers.Raymond Douville, Assistant Secretary of the 1'rocilice.24945 4408-65\u2014 1419.67 Lea Editions J.-M.Doré bac.Notice is given that, under Part I of tlie Companies Act, Supplementary letters patent, lu-,u in:: dale the 30th day of April.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"J.-M.Doré inc.\", incor|hiraled by letters paient dated the 25th day of November, 1963, I.changing its name to that of \"Le- Editions J.-M.Doré inc.\"; 2.extending it- power*.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Produce.24945 5056-03-1420 47 Entreprises Gilles Cloutier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Ixii des compagnies, le lieutenunt-gouverneur de lu province u accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1908, à la compagnie «Gilles Cloutier inc., constituée par lettres patentes en date du I4e jour de novembre 1907, changeant son nom en celui de « Entreprises Gilles Cloutier inc.».Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.24945-0 4701-67\u20141419/126 Équipements Universels Nupierville inc.Universal Equipment Napierville Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 17e jour d'avril 1908.à la compagnie « Équipements Universels Napierville inc.», constituée pur lettres patentes en dute du 16e jour d'avril 1904.1° changeant son nom en celui de « Équipements Universels Napierville inc.\u2014 Universal Equipment Napierville Inc.»; 2° modifiunt les dispositions de ses lettres patentes.Lt sous-secrétaire dc la produce, Raymond Douville.24945-0 550-64 - 1419/68 Entreprises Cilles Cloutier inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, liearing date the 30th day of April, 190S.have been issued by the Lieutenant-Governor of I he Province to \"Gilles Cloutier inc.\", incorporated by letters patent dated the l4thdayof November, 1907.changing its name to tliat of \"Entreprises Gilles Cloutier inc.\".Raymond Douville.Assistant Secretary of the Produce.24945 4701-67\u20141419 120 Équipements Universels Nupierville inc.I'niversal Equipment Napierville Inc.Notice is given that, under Part I of Hie Companies Act.supplementary letters paient, bearing date the 17th day ol April.1908.have lieen issued by the Lieutenant-Governor of Jin' Province to \"Équipements Universels Napierville inc.\".incorporated by letters patent dated April 15, 1904.I.changing its name to that of \"Équipements Universels Napierville inc.I inversai Equipment Napierville Inc.\"; 2.amending the provisions of its letters paient.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Prodm ft 24945 550-64\u20141419,68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.21 3255 Gestion Roronat Itée Gestion Boronat Itée lloronat Holdings Ltd.Boronut Holdings Ltd.'vis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date «lu 24e jour d'avril 1068.à la compagnie « St.Maurice Tra-velodgc Inc.», constituée par lettres patentes en date du 26c jour dc mars 1968, changeant min nom en celui dc « Gestion Boronat liée \u2014 Boronat Holdings Ltd.».Le sous-seerftaire de la prorince, Raymond Douville.24945-0 1372-08 \u20141419/70 Notice is given tliat, under l'art I of the Companies Act, supplementary letters patent, liearing date the 24th day ol April.1908, liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"St.Maurice Travclodge Inc.\", incorporated by letters patent dated the 26th day of March, 1968, changing its name to that of \"Gestion Boronat liée \u2014 Boronat Holdings Ltd.\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Produce.24945 1372-68\u20141419/70 Emery Holzl et Associés inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première part ie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29c jour d'avril 1968, à la compagnie « Emery Holzl et Associés inc.», augmentant son capital de $10,000 à $100.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 600 actions privilégiées d'une vali ur au pair de $100 chacune.Le sous-secretaire de la prorince, Raymond Douville.21945-0 1581-05 \u20141420/0 Emery Holzl et Associés inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor ol the Province to \"Emery Holzl et Associés inc.\", increasing its capital slock from $40.000 to $100.000.the additional sluire capital being divided into 600 preferred shares of a par value of $100 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 1581-65 \u2014 1420/6 I 'Hôpital d'Youvillc de Sherbrooke Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 9e jour dc juin 1967, à la corporation « L'Hôpital d'Youvillc de Sherbrooke», 1° étendant ses pouvoirs; 2° augmentant le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut posséder de $800,000 il $11,000,000.Le sous-seerftaire de la produce, Raymond Douville.21915-0 15848-52\u2014 1376/59 L'Hôpital d'Youvillc de Sherbrooke Notice is given that, under the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 9th day of June, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"L'Hôpital d'Youvillc de Sherbrooke\"; 1.extending its powers; 2.increasing the amount to which the annual income from the immovable property which the corporation may hold is to be limited from $SOO,000 to $3,000,000.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 15848-52 \u2014 1376/59 la Jeune Chambre de la Sarre inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 26c jour d'avril 1968, à la eoriwration « Jeune-Commerce de La Sarre », constituée en corporation par lettres patentes du 16e jour de mai 1962, changeant son nom en celui de « La Jeune Chambre de La Sarre inc.».Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 11819-62 \u2014 1419/127 La Jeune Chambre dc La Sarre inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Jcunc-Comnicrce de La Sarre\", incoriiorated by letters patent dated the 15th day of May, 1962, changing its name to that of \"La Jeune Chambre dc La Sarre inc.\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 11819-62\u20141419/127 Laval Industrial Association L'Association Industrielle Laval Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1968, à « La«aJ Industrial Association », constituée en corporation par lettres patentes du 28e jour de mars 1960, 1° changeant son nom en celui de « Laval Industrial Association \u2014 L'Association Industrielle Laval »; 2° étendant ses pouvoirs.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 11024-60 \u2014 1420/11 Laval Industrial Association I.'Associaiion Industrielle Laval Notice is hereby given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Laval Industrial Association\", incorporated by letters patent dated the 28th day of March, 1960, 1.changing its name to that of \"Laval Industrial Association \u2014 L'Association Industrielle Laval\"; 2.extending its powers.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 11024-60\u20141420/11 3256 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 2k Lcmco liée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1968, à la compagnie * Lemco Itée », étendant ses pouvoirs.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2J945-0 11462-59\u2014 1419/121 M R Realties Corp.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 19e jour d'avril 1968, ù la compagnie* Mon-Mart Bowling Inc.constituée par lettres patentes en date du 3c jour d'avril 1962, 1° changeant son nom en celui dc «MB Realties Corp.» ; 2° augmentant ses | khi voir-.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 11444-62\u20141419/82 Moreau's Barber School Incorporated Ecole dc Barbier Moreau incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1968, à la compagnie « Moreau's Barber School Incorporated », constituée par lettres |>atentes en date du 18e jour de septembre 1935, changeant son nom en celui de « Moreau's Barl>er School Incorporated \u2014 Ecole de Buriner Moreau incorporée ».Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-o 1828-35 \u20141419/35 Nutofin Ltd.Avis est donné qu'en vertu «le la première pai t le «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patente, supplémentaires en date du 25e jour d'avril 1968, à la compagnie « Natofin Lt«l.», augmentant son capital «le 8225,000 à 8500.000, le capital actions additionnel étant en 275,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 cliacune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 1170-63\u2014 1419/120 Bernard Papineau inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentai supplémentaires en date du 17e jour «l'avril 1968, à la compagnie « Bernard Papi-neau inc.», modifiant les privilèges et restrictions afférents aux actions privilégiées.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-0 1051-67 \u20141419/78 Les Peres Pré mon très Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'avril 1968, à la corporation « Les Pères Prémontrés », Ler Itée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th ilay of April, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Lemco Itée\", extending its powers.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 11462-59 \u20141419/121 M B Realties Corp.Notice is given that, under Part I of the ('(impunies Act, supplementary letters patent! bearing date the 19th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Mon-Mart Bowling Inc.\", incorporated by letters patent dated the 3rd day of April, 1962, 1.changing its name to that of \"M B Realties Corp.\"; 2.extending its powers.24945-0 Raymond Douville.Assistant Secretary of the Provint-,-, 11444-62\u20141419/82 Moreau's Barber School Incorporated École de Barbier Moreau incorporée Notice is given that, uiuler Part I of the Companies Act, supplementary letters paient, liearim: date the 24th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Moreau's Barber School incorpo-rated\", incorporated by letters patent dated the 18th day of September, 1935, changing its name to that of \"Moreau's Barber School incorporated \u2014 Ecole «le Barbier Morcau incorporée\".Raymond Douvii.i.i.Assistant Secretary of the Province.24945 1828-35\u2014 1419,35 N'ali.fin Ltd.Notice is given tliat, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April, 1908, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Natofin Ltd.\", increasing its capital from $225,000 to $500,000, the additionnai capital stock being divided into 275,000 common sliares of the par value of $1 each.24945-0 Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province, 1170-63\u2014 1419,120 Bernard Papineau inc.Notice is given tliat, uniler Part I of the Companies Act, supplementary letters pilent, bearing date the 17th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Bernard Papineau inc.\", amending the privileges and restrictions relating to the preferred sliares.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.1051-67\u2014 1419,78 24945 Les PI-res Prémontrés Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Les Pères Prémontrés\", 1.extending QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 19G8, Vol.100, No.SA 3257 1\" étendant ses pouvoirs; 2° augmentant le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation .le $150,000 à $1,000,000.Le sous-secrêiaire de la province, Raymond Douville.24945-0 9044-49 \u2014 1419/116 its powers; 2.increasing tlie amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and own from $150,000 to $1,000,000.Raymond Douville, Assistant Secretary of Ike Province.24945 9044-49 - 1419/116 Place Bonaventure inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de mai 1008, à la compagnie « Place Bonaventure inc.», 1* augmentant son capital par la création dc 12.000.000 d'actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair; 2° modifiant les dispositions de ses lettres patentes; 3° redésignant ses actions catégorie * A » et « B » sans valeur nominale ou an pair comme des actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24910 863-64 \u20141420/67 Place Bonaventure inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Place Bonaventure inc.\", 1.increasing its capital by the creation of 12,000,000 common shares without nominal or par value; 2.modifying the provisions of its letters patent; 3.redesignating its class \"A\" shares and class \"B\" shares without nominal or par value as common shares without nominal or par value.Raymond Douville, Assistant Secretari/ of the Province.24945-0 863-64 \u20141420/67 Place Vanier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour d'avril 1908, à la compagnie « Place Vanier inc.augmentant son capital dc $200,000 à $2\">0.000, le capital-actions additionnel étant divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 822-1968\u2014 1419/119 Place Vanier inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Place Vanier inc.\", increasing its capital from $200,000 to $250.000.the additional capital shares being divided into 5,000 common sliares of $10 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 822-1968 \u2014 1419/119 Poirier Automobile inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1908, à la compagnie « Poirier Automobile inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.24945-0 12034-61 \u2014 1420/15 Poirier Automobile inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of April.1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Poirier Automobile inc.\", extending its powers.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945 12034-61 \u2014 1420/15 Les Promotions TaiBon Itée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour de janvier 1967, à la compagnie « Efficiency Developments Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 18e jour de février 1959, changeant son nom en celui de « Les Promotions Taillon liée».Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.«Wj 10399-59\u20141419/39 Les Promotions Taillon Itée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 26th day of January, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Efficiency Developments Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 18th day of February, 1959, changing its name to that of \"Les Promotions Taillon Itée\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 10399-59\u2014 1419/39 Quebec Cartier Mining Company Lu Compagnie Minière Québec Cartier Avis est donné qu'en vertu de la première Partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres Patentes supplémentaires en date du 25e jour \u2022Javnl 1968, à la compagnie « Quebec Cartier Mining Company», constituée par lettres pa- Qucbec Cartier Mining Company-La Compagnie Minière Québec Cartier Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Quebec Cartier Mining Company\", incorporated by letters patent dated the 26th 3268 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 19GS, 100' année, n\" SA tentes en date du 26e jour de janvier 1957, changeant son nom en celui de « Quebec Cartier Mining Company \u2014 La Compagnie Minière Québec Cartier ».Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 10380-57\u2014 1420/19 day of January, 1957, changing ist name to that of \"Quebec Cartier Mining Company \u2014 Lu Compagnie Minière Québec Cartier\".Raymond Dou villi:, Assistant Secretary of the Province.24945-0 10380-57 \u2014 142019 Raco Manufacturing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour d'avril 1908, à la compagnie « Masonry Restoration Ltd.'\u2014Maçonnerie Restauration Itée», constituée par lettres patentes en date du 7e jour de juin 1967, eliangeant son nom en celui dc « Raco Manufacturing Limited ».Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 2593-67 \u2014 1420/20 Raco Manufacturing Limited Notice is given tliat, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 3rd day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Masonry Restoration Ltd.\u2014Maçonnerie Restauration Itée\", incorporated by letters patent dated the 7th day of June, 1967, changing its name to that of \"Raco Manufacturing Limited\".Raymond Douvilix, Assistant Secretary of the Province.24945-0 2593-67 - 1120/20 Rustex Mining Corporation (No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, le lieutenant-gouverneur dc la province u accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 19e jour d'avril 1968, à la compagnie « Rusty Lake Mining Corporation » (No Personal Liability), constituée par lettres patentes en date du 2e jour d'avril 1959, 1° changeant son nom en celui de « Rustex Mining Corporation » (No Personal Liubility); 2° diminuant son capital de $4,000,000 à $1,335,790.75, le capital annulé étant divisé en 2,004,2091^ actions d'une valeur au pairde$l chacune: 3° augmentant son capital de $1,335,790.75 ù $5,000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 3,064,20914 actions d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 11209-59\u2014 1419/84 Rustex Mining Corporation (No Personal Liability) Notice is given that, under Mining Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 19th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Rusty Lake Mining Corporation\" (No Personal Liability), incorporated by letters patent dated the 2nd day of April, 1959, 1.changing its name to that of \"Rustex Mining Coriwration\" (No Personal Liability); 2.reducing its capital from $4,000,000 to $1,335,790.75, the capital -lock annulled being divided into 2,064,209'., shares of the par value of $1 each; 3.increasing its capital from $1,335,790.75 to $5,000.000, the additionnai capital stock being divided into 3,664,2091i shares of the par value of $1 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 11209-59 \u2014 14I9/S4 Stamco Incorporated Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1908, à la compagnie « McRobert Spring Incorporated », constituée par lettres patentes en date du 15e jour de mars 1961, changeant son nom en celui de «Stamco Incorporated*.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945 11041-61\u2014 1419/48 Stamco Incorporated Notice is given that, under Part I oi the Companies Act, supplementary letters paient, bearing date the 24th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"McRobert Spring Incorpora led', incorporated by letters patent dated the 15th day of March, 1961, changing its name to that to \"Stamco Incorporated\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.24945-0 11041-61 \u2014 1419/48 Le Téléphone de Contrecoeur Itée Contrecoeur Telephone Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16e jour d'avril 1968, à la compagnie « Le Téléphone de Contrecoeur Itée -Contrecoeur Telephone Ltd.», augmentant son capital de $400,000 à $2.000,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 160,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24945-o 12109-59\u2014 1419/50 Le Téléphone de Contrecoeur Itée Contrecoeur Telephone Ltd.Notice is given that, under Part I of I lie Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor ol the Province to \"Le Téléphone de Contrecoeur Itée \u2014 Contrecoeur Telephone Ltd.\", increasing its capital from $400,000 to $2,000,000, the additional capital shares being divided into 100,000 common shares of a par value of $10 each.24945 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.12109-59 \u2014 1419/50 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.Si 3259 Vision Textiles Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1968, à la compagnie « Dynamic Value Inc.Valeur Dynamique inc.», constituée par lettres patentes en date du 14e jour d'octobre 1965.I.changeant son nom en celui de « Vision Textiles Inc.»; 2.modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Douville.21945 4534-65 \u20141419-87 Vision Textiles Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 24th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Dynamic Value Inc.\u2014 Valeur Dynamique inc.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of October, 1965, 1.changing its name to that of \"Vision Textiles Inc.\"; 2.modifiying the provisions of its letters patent.24945-0 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.4534-65 \u2014 1419-87 Arrêtés en Conseil Orders in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1337 Québec, le 1er mai 1968.Prisent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un accord entre la Société d'habitat ion du Québec et la Société Centrale d'Hypothèques et dc I,ogcmcnt pour le financement de programmes d'habitation par des organismes sail\" but lucratif.ATTENDU qu'en vertu dc l'article 71 de la loi île la Société «l'habitation du Québec (15-16 Elisabeth II.chapitre 55), la Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur n conseil, conclure tout accord avec le gouvernement «lu Canada, ou tout organisme dc celui-ci, afin «le faciliter l'exécution «le la présente loi; ATTENDU que.la Société d'habitation du Qtié-liee et la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement, organisme du gouvernement du Canada, se sont entendues sur un accord, dont le- termes et conditions sont substantiellement conformes au texte reproduit en annexe « A » et-dessous, prévoyant le financement |>our un montant estimé à 871.701,600 de programmes d'habitation par des organismes sans but lucratif au cours de l'exercice financier 1968-69 et dc tout autre programme d'habitation par des organismes SUU luit lucratif qui pourra, pendant le même exercice financier, être approuvé conformément à la loi «le la Société d'habitation du Québec; ATTENDU que la Société par sa résolution numéro 234 du 11 avril 1968.prie le lieutenant-gouverneur en conseil de l'autoriser A conclure ledit accord avec la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement; h.est ordonne, sur la proposition «le l'honorable ministre «les Affaires municipales, ce qui suit : La Société d'iiahitation du Québec est autorisée A conclure avec la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement un accord dont les ternies et conditions seront substantiellement conformes au texte reproduit en annexe * A » a-dessous, prévoyant le financement, au cours de l'exercice financier 1968-69, dc 140 programmes d'habitation par des organismes sans but lucratif Pour un montant estimé a 871,701,600 et le financement de tout autre programme d'habitation par des organismes sans but lucratif qui pourra pendant le même exercice financier, être approuvé conformément à la loi de ls Société d'habitation du Québec.Copie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exfeutif, D.Tanouay.Order in Council Executive Council Chamber Number 1337 Québec, May 1, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an agreement between The Québec Housing Corporation and the Central Mortgage and Housing Corporation for the financing of housing programs by non-profit organizations.Whereas pursuant to section 71 of the Québec Housing Corporation Act (15-16 Elizabeth II.cliapter 55), the Corporation may, with the authorization of the Lieutenant-Governor in Council, enter into any agreement with the Government of Canada, or any body thereof, to facilitate the carrying out of that Act: Whereas the Quebec Housing Corporation anil the Central Mortgage and Housing Cor- Kration, a body of the Government of Canada, ve entered into an agreement, the terms and conditions of which conform substantially with the text reproduced in Annex \"A\" below, providing for the financing of an estimated $71.701.600 in housing programs by non-profit bodies during the 1968-69 fiscal year, and of any other housing program by non-profit organizations which may, during the same fiscal year, be approved pursuant to the Québec Housing Corporation Act; Whereas the Corporation, by its resolution number 234, bearing date the 11th day of April, 1968, requests the Lieutenant-Governor in Council to authorize its entry into the said agreement with the Central Mortgage ami Housing Corporation; It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Municipal Affairs, tliat: The Qucliec Housing Cor|>oration is authorized to enter into an agreement with the Central Mortgage and Housing Corporation, the terms and conditions of which conform substantially to the text reproduced in Annex \"A\" below, providing for tlie financing, during the 1968-69 fiscal year, of 140 housing programs by nonprofit bodies for an estimated $71,701,600 and the financing of any other housing program by non-profit bodies which may, «luring the same fiscal year.I>c approved pursuant to the Québec Housing Corporation Act.Certified copy.D.Tanouay, Acting Clerk of the Executive Council. 3200 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n* 24 Convention passée en triplicate ce 17e jour de mai 1968; entre La Société Centrale d'Hypothèque et de Logement, (ci-après appelée « la Société»), d'une part, Et La Société d'habitation du Québec, (ci-après appelée « la Société du Québec »), d'autre part, Attendu que la Société peut, en vertu des dispositions de l'article 16A de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, effectuer des prêts à un organisme sans but lucratif, propriété exclusive du gouvernement d'une province, à des fins de construction ou d'acquisition et de transformation de projets de logement pour personnes à faible revenu; Et attendu que la Société du Québec, en vertu des dispositions de la Loi de la Société d'habitation du Québec, est un organisme sans but lucratif, propriété exclusive du gouvernement de la province de Québec; Et attendu que la Société du Québec peut, en vertu des dispositions de l'article 71 de la Loi de la Société d'habitation du Québec, conclure tout accord avec le Gouvernement du Canada ou tout organisme dc celui-ci afin de faciliter l'exécution de cette loi; Et attendu que par l'arrêté en conseil no 1337, daté du 1er jour de mai 1968, le lieutenant-gouverneur en conseil a autorise la Société du Québec à conclure avec la Société un accord dont les conditions, en substance, sont celles de la présente convention; Et attendu que par le décret CP.1968-761 daté du 25c jour d'avril 1968, adopté selon les dispositions de l'article 16A de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, le gouverneur en conseil au autorisé la Société à conclure la présente convention en vue de prêter une somme totale n'excédant pas $71,701,600 aux fins de permettre à la Société du Québec d'entreprendre les projets de logement pour personnes à faible revenu décrits à l'annexe « A » des présentes, chaque projet de logement ci-après mentionné devant être appelé « le projet » ; En conséquence, la présente convention fait foi des ententes suivantes entre les parties: 1.Prêt 1° Pourvu que la Société ait reconnu, selon l'article 16A de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, l'admissibilité au financement de chaque projet dc logement désigné à l'annexe « A », la Société convient par les présentes d'avancer à la Société du Québec, en tenant compte de la limite imposée par le paragraphe 1 (5) de la présente convention, une somme totale n'excédant pas $71,701,000 et convient de délwurser ladite somme pourvu que les conditions île la présente convention aient été respectées; 2° Ln Société du Québec soumettra à la Société, à son bureau régional du Québec, 2350, chemin Manella, Ville Mont-Royal, en une forme acceptable aux deux parties, une demande de déclaration d'admissibilité et d'estimation du montant du prêt pour chaque projet; 3° La demande de déclaration d'admissibilité et d'estimation du montant du prêt pour cliaque projet doit être accompagnée de plans, de devis descriptifs el de devis estimatifs des coûts du projet tel que requis par la Loi de la Société d'habitation du Québec; 4e La Société, dans les 21 jours suivant la réception de ladite demande, émettra à la Société du Québec à 1995, ouest, boul.Cliarest, Ste-Foy, This agreement made in triplicate the 17th day of May 1968; between: Central Mortgage and Housing Corporation, (hereinafter called \"the Corporation\"), of the first part: And, The Québec Housing Corporation,(hereinafter called \"the Québec Corporation\"), of the second part: Whereas the Corporation may pursuant to the provisions of section 16A of the National Housing Act, 1954, make loans to a non-profit corporation wholly owned by the government of a province for the construction or acquisition and conversion of housing projects for low income persons; And whereas the Quélicc Corporation, pursuant to the Québec Housing Corporation Act, is a non-profit corporation wholly owned by the government of the Province of Québec; And whereas the Quelle Corporation may, pursuant to section 71 of the Québec Housing Corporation Act, make any agreement with the Government of Canada or any body thereof to facilitate the carrying out of that Act; And whereas by Order-in-Council P.C.1337 dated the first day of May, 1968.the Lieutenant-( iovernor-in-Council has authorized the Québec Corporation to enter into an agreement substantially in the terms of this agreement with the Corporation; And whereas by Order-in-Council P.C.1968-761 dated the 25th day of April 1968, passed pursuant to section 16A of the National Housing Act.1954.the Govcrnor-in-Council has authorized the Corporation to enter into this agreement to lend a total amount not exceeding $71,701.600.for the purpose of enabling the Québec Corporation to undertake the housing projects for persona of low income outlined in Schedule \"A\" hereto annexed, each housing project being hereinafter referred to as \"the project\"; Now therefore this agreement witncsselh that the parties hereto agree as follows: 1.Loan 1.Provided the Corporation has recognized under section 16A of the National Housing Act 1954, the eligibility for the financing of each housing project listed in Schedule \"A\", the Corporation hereby agrees to advance j,o the Québec Corporation, subject to the limitation imposed by section 1 (5) of this agreement, a total sum not exceeding $71,701,600 and undertakes to disburse the said sum provided the terms and conditions of this agreement have !>cen complied with; 2.The Québec Corporation will submit to the Corporation at its Quéliec Regional Office.2350 Manella Road, Town of Mount Royal an application in a form acceptable to both parties fora declaration of eligibility and for an estimate of the loan amount for each project; 3.The application for a declaration of eligibility and for an estimate of the loan amount for each project shall be accompanied by plans, specifications and a detailed estimate of costs for the project as required by the Québec Housing Corporation Act; 4.The Corporation will, within 21 days from the receipt of the application, issue to the Québec Corporation, at 1995 West, Charest Blvd., QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.il 3261 Quéliec 10, une declaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt ou, dans le cas contraire, en informera par écrit la Société du Quéliec; 5° Il est convenu entre les parties que la déclaration d'admissibilité a pour seul but de déterminer que le projet peut faire l'objet d'un prêt en vertu de la Loi Nationale sur l'Habitation et de fixer le montant du prêt; la Société du Quéliec est seule responsable de l'évaluation du besoin, île l'acceptation de l'emplacement et du nombre ainsi que de la grandeur des logements de l'approbation de la planification de l'ineliitccture, des plans et devis, des normes et conditions d'occupation et aucun certificat d'admissibilité ne sera refusé ou retenu pour des considérations basées sur ces sujets ou sur d'autres de même nature; 6° Le montant du prêt pour chaque projet n'excédera pas 90% du coût réel du projet tel qu'accepté par les deux parties; 7° La Société du Québec peut, à même les sommes qui lui sont avancées pour un projet, elTcelucr un prêt pour la construction ou l'acquisition et la transformation d'un projet de logement pour personnes à faible revenu n un organisme sans but lucratif, reconnu par la Société du Québec.|M)iirvu qu'aucune partie du revenu de tel organisme ne soit payable ou autrement mise à la disposition des propriétaires, membres ou actionnaires de tel organisme sans but lucratif pour leur liénéficc personnel.2.Coût du projet: La Société, aux fins d'établir le montant du pu I |k)iir chaque projet, inclucra comme partie all coût réel du projet ce qui suit: « Les sommes réellement et effectivement payées par la Société du Québec ou par un organisme sans but lucratif pour l'acquisition de terrain, la construction ou l'acquisition et la transformation du projet et l'exécution des travaux requis pour transformer chaque unité dc logement du projet; Les sommes réellement et effectivement payées pour les matériaux utilisés lors de la transformation du projet lorsque lesdites sommes ne sont pas comprises dans le paragraphe «a» ci-dessus; c) Les sommes réellement et effectivement payées pour l'aménagement du terrain, les travaux paysagers et pour l'installation ou la réparation d'aqueducs, égouts et autres services; d) Les sommes réellement déboursées pour services juridiques, taxes, permis de construction, honoraires et coûts des services d'architectes, d'arpenteurs, d'ingénieurs et autres; il L'intérêt payable jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; /) Les frais administratifs encourus par la Société du Québec en effectuant le prêt h un organisme sans but lucratif d'après entente entre les parties; !/) Les primes payées par la Société du Québec, l'organisme sans but lucratif ou l'entrepreneur pour de l'assurance contre les pertes occasionnées par l'incendie ou d'autres risques, ayant trait au projet jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; k) Les coûts d'exploitation du projet moins les revenus bruts jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; 0 Tels autres coûts et sommes dont les parties peuvent convenir entre elles.St.Foy, Québec 10, a declaration of eligibility and an estimate ot the loan amount or, if otherwise, inform in writing the Québec Corporation; 5.It is agreed between the parlies that the declaration of eligibility is for the sole purpose of recognizing that the project is eligible for a loan under the National Housing Act and determining the amount of each loan; the Quéliec Corporation has the exclusive responsibility of assessing the need for the project, of accepting the site, the number and size of units, of approving the planning, the architecture, the plans, the specifications, of determining the norms anil conditions of occupancy and the Corporation agrees that a declaration of eligibility shall not be refused nor withheld for any consideration related to these or other matters of the same nature; 6.The amount of the loan with respect to each project shall not exceed 90% of the actual cost of the project as accepted by both parties; 7.The Quéliec Corporation may, out of the monies advanced to it for a project, make a loan for the construction or acquisition and conversion of the housing project for persons of low income to any non-profit corporation accepted by the Québec Corporation provided that no part or the income of any such non-profit corporation shall be payable or otherwsc available for the personal benefit of any proprietor, member or sliareholder of such non-profit corporation.2.Cost of the project: The Corporation will, for the purpose of determining the amount of loan for each project, include as part of the actual cost of the project, the following: (a) Amounts actually and properly paid by the Québec Corporation or by a non-profit corporation for the acquisition of land, the construction or the acquisition and conversion of the project and the performance of work required to convert each housing unit in the project; (b) Amounts actually and properly paid for materials used in the conversion of the project wdicre such amounts are not included under \"o\" above; (e) Amounts actually and properly paid for landscaping, site improvements, and for installing or repairing water, sewer and other services; (d) Amounts actually paid for legal services, taxes, building permits, and fees and costs for the services of architects, land surveyors, engi-ners and others; (e) Interest payable to the interest adjustment date; (/) The administration costs incurred by the Québec Corporation in making the loan to a non-profit corporation as agreed upon between the parties; (g) Premiums paid by the Québec Corporation, the non-profit corporation or the contractor for insurance against loss by fire or other perils in respect of the project to the interest adjustment date; (h) The costs of operating the project less gross revenues up to the interest adjustment date; and (») Such other costs and amounts as may be agreed upon between both parties. 3262 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n' 2A 3.Débours: 1° Lorsqu'une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt, relativement ù un projet, ont été émises à la Société du Québec, la Société du Québec peut, ù l'occasion, pendant la période de construction ou d'acquisition et dc transformation du projet, demander à la Société un débours au compte du prêt pour toute partie du projet qui a été achevée; 2° Tout débours subséquent, au compte du prêt, pour chaque projet peut être effectué mensuellement; 3° Une demande de débours au compte d'un prêt doit être accompagnée d'un certificat d'un oflicier autorisé dc la Société du Québec établissant: a) la partie du projet qui a été achevée, et b) l'estimation du coût dc la partie du projet qui a été achevée; 4° Sur réception d'une demande de débours au compte d'un prêt, la Société effectuera, aussitôt que possible, le débours à la Société du Québec d'une somme n'excédant pas flO% du coût réel du projet encouru ù la date du débours, tel qu'accepté par les deux parties, moins le montant égal aux débours déjà effectués à la Société du Québec pour le projet.4.Remboursement: 1° Le montant du principal dc chaque prêt doit être le montant du prêt avancé à la Société du Québec pour le projet; le taux d'intérêt sur chaque prêt doit être le taux d'intérêt approuvé par le gouverneur en conseil et en vigueur à la date de l'émission de la déclaration d'admissibilité; 2° Chaque prêt, effectué par la Société du Québec à un organisme sans but lucratif ù même les sommes qui lui sont avancées en vertu île la présente convention pour la construction ou l'acquisition et la transformation du projet, doit porter intérêt au même taux que celui qui est stipulé dans la déclaration d'admissibilité pour ce projet; 3° L'intérêt sur chaque prêt doit être calculé semestriellement, non à l'avance, aussi bien après qu'avant l'échéance, jusqu'au remboursement du prêt: l'intérêt doit être imputé sur les sommes avancées à l'occasion et calculé à compter des dates respectives de ces avances jusqu'au 1er jour de juillet suivant la date de parachèvement du projet (appelée dans la présente convention « la date d'ajustement des intérêts»); ledit intérêt deviendra alors dû et devra être payé comptant ou par chèque, et, par la suite, le montant du capital de chaque prêt ainsi que l'intérêt sur icelui au taux susdit deviendra dû et devra être payé annuellement en versements combinés égaux le 1er jour de juillet de toutes et chacune des années pendant une période n'excédant pas 50 ans; le solde entier du capital et de l'intérêt deviendra alors dû et devra être payé; 4° La Société du Québec aura, en tout temps avant la date d'expiration de ladite période, le privilège dc payer sans pré-avis ni boni la totalité ou toute partie de tout prêt impayé.5.Garantie: Le 1er juillet de chaque année, la Société du Québec s'engage à remettre à la Société des obligations, en une forme acceptable aux deux partie, dont le montant en capital doit être égal 3.Disbursements: 1.Where a declaration of eligibility and an estimate of the loan amount in respect, of a project have been issued to the Québec Corporation, the Québec Corporation may from lime to time during the period of construction or acquisition and conversion of the project apply to the Corporation for a disbursement on the loan with respect to any part of the project that has been completed; 2.Any subsequent disbursement on the loan may for each project be made on a monthly basis; 3.An application for a disbursement on a loan shall be accompanied by a certificate of an authorized olliccr of the Quebec Corporation setting out : (a) the part of the project that has been completed, and (l>) the estimated cost of the part of the project that has been completed; 4.On receipt of an application of a disburse, ment on a loan, the Corporation will make the disbursement to the Québec Corporation, as soon as possible, in an amount not exceeding 90% ol the actual cost of the project incurred to the dule of the disbursement, as accepted by both parties, less the amount equal to disbursements previously made to the Québec Cor|mra-tion in respect of the project.4.Repayment: 1.The amount of principal money for each loan shall be the amount of the loan advanced to the Québec Corporation for the project: and the rale of interest for each loan shall be the interest rate approved by the Governor in Council and in effect at the time the déclaration of eligibility is issued; 2.Each loan that the Québec Corporation nukes to a non-profit corporation out of the monies advanced to it under this agreement for the construction or acquisition and conversion of the project shall be at the same rate of interest stated in the declaration of eligibility for Unit project; 3.Interest on each loan shall lie calculated lialf-ycarly not in advance, as well after as before maturity, until the loan is paid, and the interest shall be chargeable on the amounts from time to time advanced, computed from the respective dates of such advances to the first day of July following the completion of the project (referred to in this agreement as the \"interest adjustment date\") at which time the said interest shall become due and be paid by cash or cheque, and thereafter the principal sum on each loan together with interest thereon at the aforesaid rate shall become due and be paid annually in equal blended payments on I he first day of July in each and every year for a period not exceeding 50 years when the full balance of principal and interest shall become due and be paid; 4.The Québec Corporation shall have the privilege at any time before the expiry date of the said period of paying the whole or any part of any loan outstanding without notice or bonus.5.Security: On July 1st in each year, the Québec Corporation agrees to deliver to the Corporation debentures, in a form acceptable to both parties, equal in principal amount to the principal ad- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 16.1968, Vol.100, JVo.21 3263 ù la somme de capital avancée sur chaque prêt complètement débourse.L'obligation de la Société du Québec de rembourser chaque prêt ainsi que l'intérêt sur icelui doit, sur remise de chacune des obligations, être censée nvoir été remplacée par rengagement dc les rembourser en conformité avec les conditions d'icelles.0.Inspections: 1 \" Le projet sera conforme aux normes minimales d'habitation acceptables aux deux parties: 2' La Société du Québec assurera les services d'inspection de la construction ou de la transformation des projets; i° La Société peut, en vertu d'ententes établies par les deux parties, examiner le projet dc logement afin de s'assurer que le travail deconstruct ion ou de transformation a été effectué d'une façon raisonnablement conforme aux plans approuvés, au cahier des charges, et aux normes de construction.7.Vérification: 1° La Société du Québec doit soumettre un état dûment certifié indiquant le coût de la construct ion ou dc l'acquisition et de la transformation du projet dès qu'il est parachevé; 2\" La Société du Québec s'entendra avec la Société afin dc permettre l'examen de tous les livres, dossiers et comptes se rapportant au pro-ji t, aux lins d'en vérifier le coût.8.Défaut: 1° Dans l'éventualité d'un défaut de payer tout versement d'argent exigible en vertu de la présente convention, ou sur infraction à toute stipulation ou entente qui y est contenue après que la totalité ou une partie dc tout prêt aura été avancée en vertu dc la présente convention, sujet cependant h ce que la Société donne à la Société du Québec un avis dc remédier le défaut nu l'infraction dans un délai dc trente (30) jours, le solde entier du capital de ce prêt ainsi que l'intérêt sur icelui, alors impayés, deviendront, lu choix dc la Société, immédiatement dûs et exigibles; 2* Dans l'éventualité ou le projet cesserait d'être un projet de logement tel que défini à l'article 16A de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, le solde entier du capital dc ce prêt lùuj que l'inteftt sur icelui, alors impayés, deviendront, au choix de la Société, immédiatement dûs et exigibles.C Prescription delà convention: SI une demande dc déclaration d'admissibilité pour un projet désigné s 1 annexe * A » n'a pas été reçue le 31 mars 1969, le projet ne sera pas admissible à un prêt en vertu dc la présente convention.10.Projets additionnels: Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil donnée en vertu des dispositions dc l'article 16A dc la Loi nationale de 1954 sur l'habitation et sous réserve du respect de toutes les autres conditions de la présente convention, la Société consent à examiner les demandes de la Société du Québec, au cours de la période se terminant le 31 mars 1969, en vue d'obtenir des prêts pour des projets de logement pour personnes à faible revenu en outre de ceux désignés à l'annexe « A » et, s'ils sont admissibles, à émettre une déclaration d'admissibilité et d'estimation du montant du prêt.vanced on each loan fully disbursed.The Québec Corporation's obligation to repay each loan together with interest thereon shall upon delivery of each debenture, lie deemed to be substituted by the obligation to repay each debenture in accordance with the terms thereof.6.Inspections: 1.The project will conform with minimum housing standards acceptable to both parties; 2.The Québec Corporation will provide inspections of construction or conversion of the projects; 3.The Corporation may under arrangements agreed upon by both parties inspect the housing project to ensure that the work of construction or conversion has been carried out in reasonable conformity with the approved plans, specifications, and standards of construction.7.Audit: 1.The Quéliec Corporation must, as soon as the project is completed, submit a duly certified statement of cost of construction or acquisition and conversion; 2.The Quéliec Corporation will make arrangements with the Corporation to permit examination of all books, records, and accounts maintained in respect of the project for the purpose of verifying the cost thereof.8.Default: 1.In the event of default in the payment of any instalment of any monies payable hereunder, or upon breach of any covenant or agreement herein contained, after all or part of any loan hereunder has been advanced, subject however to notice by tlie Corporation to the Quéliec Corporation to remedy the default or breach within thirty (30) days, the whole of the principal together with the interest thereon remaining unpaid on that loan, shall at the option of the Corporation forthwith become due and payable; 2.In the event the project is not maintained as a housing project within the terms of section 16A of the National Housing Act 1954, the whole of the principal together with the interest Uiereon remaining unpaid on that loan shall at tlie option of the Corporation forthwith become due and payable.9.Limitation of agreement: If an application for a declaration of eligibility on a project listed in Schedule \"A\" is not received by March 31st 1969, the project will not be eligible for a loan under this agreement.10.Additional projects: Subject to the approval of the Governor-in-Council given pursuant to section 16A of the National Housing Act, 1954, and on compliance with all other terms and conditions of this agreement, the Corporation agrees to review applications by the Québec Corporation during the period ending March 31st, 1969, for loans for housing projects for persons of low income in addition to those listed in Schedule \"A\" hereto annexed and, if eligible, issue a declaration of eligibility and an estimate of loan amount. 3264 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 21 11.Contrat d'exploitation: La Société du Québec s'engage à fournir A la Société, pour chaque projet, une copie certifiée du contrat d'exploitation exigé par le paragraphe 27 du règlement numéro 2 de la Société du Québec approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3182, le 22 novembre 1967.12.Consternation des documents: Tous les documents, pièces justificatives, dossiers et comptes se rapportant au coût de la construction ou dc l'acquisition et de la transformation du projet seront conservés pendant au moins sept (7) ans à compter dc la date de parachèvement du projet.Signé à Montréal, ce 17c jour de mai 1968.La Société centrale d'hypothèques et de logement.Le président, H.W.HlONETT.W.K.Scott.Le témoin, Alain du C.Naxtel.La Société d'habitation du Québec.Le président, Henri Dion, Le secrétaire, Conrad Deusle.Le témoin, rodolphe Laplantk.11.Operating agreement: The Québec Corporation undertakes to supply the Corporation for each project with a certifient copy of the operating agreement required under clause 27 of by-law number two of the Québec Corporation and approved by order in council number 3182, November 22nd, 1967.12.Retention of documents: All documents, vouchers, records and accounts pertaining to the cost of construction or acquisition and conversion of a project will be retained for not less than seven years from the dale of completion of that project.Signed at Montreal, that 17th day of May 1968.Central Mortgage and Housing Corporation.H.W.HlONETT, President.W.E.Scott.Alain de C.Nanti;!.Witness.Québec Housing Corporation.Henri Dion.President.Conrad Delisi.e, Secretary, rodolphe Laplante, Witness.Cédule «A»\u2014Schedule \"A\" Programmes d'habitation pour familles à revenu modique 1968-li)(')9 par organismes sans but lucratif Housing programs for low income families 1968-1969 by non profit making organizations 02 Région administrative du Saguenay-Lac Saint-Jean 02 Saguenay-Lac Saint-Jean Administrative Region Municipalité Municipality Alma Chibougamau Chicoutimi Dubcrger Neufchfltel Orsainville Drummondville Trois-Rivières Victoriaville Sherbrooke Laval La Prairie Sainte-Julic Richelieu Granby Organisme Borrower ( 'oopérative d'habitation ('oopérat ive d'habitation ( 'oopérative d'habitation Capacité (logements) Capacity (Housing units) 40 40 60 03 Région administrative de Québec 03 Quéliec Administrative Region ('oopérative d'habitation Coopérative d'habitation Coopérative d'hubitation 114 100 100 04 Région administrative des Trois-Rivières 04 Trois-Rivières Administrative Region Coopérative d'habitation Coopérative d'habitation Coopérative d'habitation 30 50 20 05 Région administrative des Cantons-dc-l'Est 05 Eastern Township Administrative Region Coopérative d'habitation 40 00 Région administrative de Montréal 06 Montréal Administrative Region ('oopérative d'habitation (\"oopérative d'habitation Coopérative d'habitation Coopérative d'habitation Coopérative d'habitation Total 240 40 60 60 20 102(1 PrHS.C.ll.L, CM.U.C.loan S 360.0(10 INI 300.0011 IH) 540.1 KHI («I $1.026.00(1 00 954.00(1 (HI 900,000 00 S 270.0011.00 450.000.00 180.001) i'\" 360.001» .00 S2.16C.000.00 300.000 00 540.000 00 540.000.00 180,000 00 18,180,000.110 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.U 3265 Programmes d'liabitation pour personnes âgées 1968-1969 Housing programs for elderly citizens 1968-1969 \t\tCapacité\t Municipalité\tOrganisme\t(lits et log.)\tPrêt S.C.H.L.M unicipality\tBorrower 01 Région administrative du\tCapacity (beds and Housing units) Bas St-Laurent - Gaspésie\tC.M.H.C.loan \t01 Lower-St-Lawrence - Gaspé Administrative Region\t\t New Carlisle\tFoyer de New Carlisle\t40\t$ 252,000.00 New Richmond\tFoyer de Richmond\t40\t252,000.00 Cap-Chat\tFoyer de Cap-Chat\t80\t504,000.00 Chandler\tFoyer de Chandler Foyer de Matane\t50\t315,000.00 Alatane\t\t90\t567,000.00 Val-Brillant\tFoyer de Val-Brillant\t32\t201,500.00 Mont-Joli\tLa Résidence\t40\t252,000.00 \tde Mont-Joli.\t\t Itimouski\tFoyer de Rimouski\t175\t1,225,000.00 \t02 Région administrative du Sagucnay-Lac-Saint-Jean\t\t \t02 Saguenay-Lac-Saint-Jean Administrative Region\t\t Chicoutimi\tFoyer Beaumanoir\t85\t$ 535,500.00 \tde Chicoutimi.\t\t Jonquière\tFoyer de Jonquière\t50\t315,000.00 Kénogami\tFoyer de Kénogami\t50\t315,000.00 Alma\tFoyer d'Alma Foyer Lac Bouchctte\t60\t378,000.00 Lac lîouchette\t\t25\t157,500.00 Nolre-Dame-de-la-Doré.Roberval\tFoyer Notre-Dame\t20\t126,000.00 \tL'auberge du Bontcmps\t60\t378,000.00 03 Région administrative de Québec 03 Québec Administrative Region Saint-Georges-Est\tFoyer du Repos\t50\tS 315.000.00 Sain t -Georges-Ouest\tFoyer St-Georges\t50\t315,000.00 Samt-Joseph-\tFoyer Mgr O.Roy\t25\t157,500.00 dc-Beauce.\t\t\t Saint-Martin\tFoyer St-Martin\t40\t252,000.00 Saint-Simeon\tFoyer de St-Siméon\t30\t189,000.00 Charlesbourg\tFoyer de Charlesbourg\t60\t420,000.00 I.oret,tcville\tFoyer de Loretteville\t50\t315,000.00 Lac Etchemin\tFoyer de Ste-Gcrmainc\t75\t472,500.00 Lambton\tFoyer Lambton\t50\t315,000.00 Sainte-Hénédine\tFoyer Familial\t40\t252.000.00 Snint-Magloire-\tFoyer de St-Magloire\t30\t189,000.00 de-Bellechasse.\t\t\t Saint-Odilon-de-\tFoyer de St-Odilon\t25\t157,500.00 Cranhournc.\t\t\t Saint-Prosper\tFoyer de St-Prosper\t50\t330,600.00 Saint-Gédéon\tFoyer de St-Gédéon\t35\t220,500.00 Levis\tFoyer de St-Joseph-dc-Lévis Inc.\t90\t630,000.00 Sainl-Romuald-\tFoyer Mgr Audet Inc.\t159\t413,000.00 d'Etehcmin.\t\t\t Lotbinière\tFoyer St-Louis-de-Lotbinière.\t20\t126,000.00 Saint-Sylvestre\tFoyer de St-Sylvestre\t30\t189,000.00 Sainte-Foy\tFoyer Ste-Foy\t50\t350,000.00 Lyster\tFoyer de Lyster\t42\t280,000.00 Saiiit-Casunir\tFoyer de St-Casimir\t25\t157,500.00 Saint-Marc-des-\tFoyer St-Marc-\t40\t252,000.00 ( arrières.\tdes-Carrières.\t\t Québec\tCorp.du Bon-Secours\t180\t1,260,000.00 Quéliec\tHospice St-Sauveur\t94\t350,000.00 Suint-Joseph-de-\tVilla de la Rivière Bleue\t35\t220,500.00 la-Rivière-Bleue.\t\t\t Hivicre-du-Loup\tVilla Frascrvillc\t88\t643,000.00 Saint-Louis-du-\tFoyer Beauséjour\t40\t252,000.00 Ha! Ha! Cédule « A » \u2014 Schedule \"A\" 3266 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n' 21 Cédule « A » \u2014 Schedule \"A\" Programmes d'habitation pour personnes Agées 1968-1969 Housing programs for elderly citizens 1968-1969 (suite) \u2014 (continued) Municipalité Municipality Organisme Borrower Capacité (lits et log.) Capacity (beds and Housing units) 04 Région administrative des Trois-Rivières 04 Trois-Rivières Administrative Region Cap-de-la-Madeleine\tFoyer du Cap-de-la-\t100 \tMadcleine.\t Saint-Thèclc\tFoyer de St-Thècle\t30 Notre-Dame-du-\tFoyer \\otrc-I)ame-du-\t40 Ron-Conseil.\tBon-Conseil.\t Drummondvillc\tChevaliers de ( 'olomb\t80 Fortiervillc\tFoyer dc Fortierville\t30 La Tuque\tFoyer dc La Tuque\t02 Saint-Tite\tFoyer Mgr Faquin Inc.\t70 Récancour\tFoyer dc Gent illy\t32 Shawinigan-Sud\tFoyer dc Shawinigan-Sud\t40 Vamachiclie\tHospice Stc-Anne\t80 Picrrcville\tFoyer de Picrrcville\t50 I,ac Mégantic Saint-Ludger Rrompton ville East Angus Coaticook Weedon 0.') Région administrative ° Le montant du prêt pour chaque projet n'excédera pas 90% du coût réel du projet tel qu'accepté par les deux parties; 7° La Société du Québec peut, à même les sommes qui lui sont avancées pour un projet, effectuer un prêt A une municipalité ou à un olllee municipal d'habitation aux fins de construire ou d'acquérir et dc transformer le projet de logement public.2.( 'oui du projet: La Société, aux fins d'établir le montant du prêt pour chaque projet, incluera comme partie du coût réel du projet ce qui suit: a) Les sommes réellement et effectivement payées par la Société du Quéliec, mie municipalité ou un ollice municipal d'habitat ion pour l'acquisition du terrain, la construction ou l'acquisition et la transformation du projet et l'exécution des travaux requis pour transformer chaque unité de iogement du projet; b) Les sommes réellement et effectivement payées pour les matériaux utilisés lors de la transformation du projet lorsque lesdites somme- ne sont pas comprises dans le paragraphe a) ci-dessus; t) Les sommes réellement et effectivement payées pour l'aménagement du terrain, les travaux paysagers et pour l'installation ou la re|iaration d'aqueducs, égouts et autres services; ih Les sommes réellement déboursées pour services juridiques, taxes, permis de construction, honoraires et coûts des services d'architectes, d'arpenteurs, d'ingénieurs et autres; e) L'intérêt payable jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; f}t Les frais administratifs encourus par la Société du Québec en effectuant le prêt à une municipalité ou à un office municipal d'habitation, d'après entente entre les parties; takes to disburse the said sum provided the terms and conditions of this agreement have been complied with; 2.The Québec Corporation will submit to the Québec Regional Office, 2350 Manella Road, Town of Mount Royal, an application in a form acceptable to both parties, for a declaration of eligibility and for an estimate of the loan amount for each project; 3.The application for a declaration of eligibility and for an estimate of the loan amount for each project .-hall be accompanied by loans, specifications and a detailed estimate of costs for the projects as required by the Québec Housing Corporation Act; 4.The Corporation will, within 21 days from the receipt of the application, issue to tlie Québec Corporation, at 1995 West, Charest Blvd., St.Foy, Québec 10, a declaration of eligibility and an estimate of the loan amount or, if otherwise, inform in writing the Québec Corporation; 5.It is agreed between the parties that the declaration of eligibility is for the sole purpose of recognizing that the project is eligible for a loan under the National Housing Act and determining the amount of each loan; the Québec Corporation has the exclusive responsibility of assessing the need for the project, of accepting the site, the number and size of units, of approving the planning, the architecture, the plans, the specifications, of determining the norms and conditions of occupancy and the Corporation agrees that a declaration of eligibility shall not be refused nor withheld for any consideration related to these or other matters of tlie same nature; 6.The amount of the loan for each project shall not exceed 90% of the actual cost of the project as accepted by both parties; 7.The Québec Corporation may, out of the moneys advanced to it for a project, make a loan to a municipality, or a municipal office bureau for the construction or acquisition and conversion of the public housing projet.2.Cost of the project: The Corporation will, for the purpose of determining the amount of loan for each project, include as part of the actual cost of the project, the following: (a) Amounts actually and properly paid by the Québec Corporation, a municipality or a municipal housing bureau for the acquisition of land, the construction or the acquisition and conversion of the project and the performance of work required to convert each housing unit in the project; (6) Amounts actually and properly paid for materials used in the conversion of the project where such amounts are not included under (a) above; (c) Amounts actually and properly paid for landscaping, site improvements, and for installing or repairing water, sewer and other services; (d) Amounts actually paid for legal services, taxes, building permits, and fees and costs for the services of architects, land surveyors, cngi-ners and others; (e) Interest payable to the interest adjustment date; (/) The administration costs incurred by the Québec Corporation in making the loan to a municipality or municipal housing bureau, as may be agreed upon between the parties; 3272 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 21 g) Les primes payées par la Société du Québec, la municipalité, un office municipal d'habitation ou l'entrepreneur pour de l'assurance contre les pertes occasionnées par l'incendie ou d'autres risques, ayant trait au projet jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; h) Les coûts d'exploitation du projet moins les revenus bruts jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; i) Tels autres coûts et sommes dont les parties peuvent convenir entre elles.3.Débours: 1° Lorsqu'une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt, relativement a un projet, ont été émises à la Société du Québec, la Société du Québec peut, à l'occasion, pendant la période de construction ou d'acquisition et de transformation du projet, demander ù la Société un débours au compte du prêt pour toute partie du projet qui a été achevée; 2° Tout débours subséquent, au compte du prêt, pour chaque projet peut être effectué mensuellement; 3° Une demande de débours relativement à un projet doit être accompagnée d'un certificat «l'un officier autorisé de la Société du Québec établissant: a) la partie du projet qui a été achevée, et 6) l'estimation du coût de la partie du projet qui a été achevée; 4° Sur réception d'une demande de débours au compte d'un prêt, la Société effectuera aussitôt que possible, le débours à la Société du Québec d'une somme n'excédant pas 90% du coût réel du projet encouru à la date du débours, tel qu'accepté par les deux parties, moins le montant égal aux débours divjà effectués à la Société du Québec pour le projet.4.Remboursement: 1° Le montant du principal de chaque prêt doit être le montant du prêt avancé à la Société du Québec pour le projet; le taux d'intérêt sur chaque prêt doit être le taux d'intérêt approuvé par le gouverneur en conseil et en vigueur à la date de l'émission de la déclaration d'admissibilité; 2° Chaque prêt, effectué par la Société du Québec à une municipalité ou à un office municipal d'habitation à même les sommes qui lui sont avancées en vertu de la présente convention pour la construction ou l'acquisition et la transformation du projet, doit porter intérêt au même taux que celui qui est stipulé dans la déclaration d'admissibilité pour ce projet; 3° L'intérêt sur chaque prêt doit être calculé semestriellement, non à l'avance, aussi bien après qu'avant l'échéance, jusqu'au remboursement du prêt: l'intérêt doit être imputé sur les sommes avancées à l'occasion et calculé à compter des dates respectives de ces avances jusqu'au 1er jour de juillet suivant la date de parachèvement du projet (appelée dans la présente convention « la date d'ajustement des intérêts ») ; ledit intérêt deviendra alors dû et devra être payé comptant ou par chèque, et, par la suite, le montant du capital de chaque prêt ainsi que l'intérêt sur icelui au taux susdit deviendra dû et devra être payé annuellement en versements combinés égaux le 1er jour de juillet de toutes (g) Premiums paid by the Québec Corporation, the municipality, a municipal housing or the contractor for insurance against loss by lire or other perils in respect of the project to the interest adjustement date; (h) The costs of operating the project less gross revenues up to the interest adjustment date; (i) Such other costs and amounts as may be agreed upon between both parties.3.Disbursements: 1.Where a declaration of eligibility and an estimate of the loan amount in respect of a project have been issued to the Québec Corporation, the Québec Corporation may from time to time during the period of construction or acquisition and conversion of the project apply to the Corporation for a disbursement on the loan with respect to any part of the project that has been completed; 2.Any subsequent disbursement on the loan may, for each project, be made on a monthly, basis; 3.An application for a disbursement in respect of a project shall be accompanied by a certificate of an authorized officer of the Québec Corporation setting out: (a) the part of the project tliat has been completed, and (b) the estimated cost of the part of the project that lias been completed; 4.On receipt of an application of a disbursement on a loan, the Corporation will make the disbursement to the Québec Corporation, as soon as possible, in an amount not exceeding 90% of the actual cost of the project incurred to the dale of the disbursement, as accepted by both parties, less the amount equal to disbursements previously made to the Québec Cor|iora-tion in respect of the project.4.Repayment: 1.The amount of principal money for each loan sliall be the amount of the loan advanced to the Québec Corporation for the project; the rate of interest for each loan sliall Ik- the interest rate approved by the Governor in Council and in effect at tlie time the declaration of eligibility is issued; 2.Each loan that the Québec Corporation makes to a municipality on municipal bousing bureau out of the moneys advanced to it under this agreement for the construction or acquisition and conversion of the project shall be at the same rate of interest stated in the declaration of eligibility for that project; 3.Interest on each loan shall be calculated half-yearly not in advance, as well after as before maturity, until the loan is paid, ami the interest shall be chargeable on the amounts from time to time advanced, computed from the respective dates of such advances to the first day of July following the completion of the project (referred to in this agreement us the \"interest adjustment date\") at which time the said interest shall become due and be paid by cash or cheque, and thereafter tlie principal sum on each loan together with interest thereon at the aforesaid rate shall become due and J* paid annually in equal blended payments on the first day of July in each and every year for a QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.SA 3273 et chacune des années pendant une période n'excédant pas 50 ans; le solde entier du capital et dc l'intérêt deviendra alors dû et devra être payé; ¦ La Société du Québec aura, en tout temps avant la date d'expiration de ladite période, le privilège de payer sans pré-avis ni boni, la totalité ou toute partie de tout prêt impayé.5.Garantie: Le 1er juillet de chaque année, la Société du Québec s'engage à remettre à la Société des obligations, en une forme acceptable aux deux parues, dont le montant en capital doit être égal à In somme de capital avancée sur chaque prêt complètement déboursé.L'obligation de la Société du Québec de rembourser chaque prêt ainsi que l'intérêt sur icelui doit, sur remise de chacune des obligations, être censée avoir été remplacer par l'engagement de les rembourses en conformité avec les conditions d'icellcs.6.Inspections: 1\" Le projet sera conforme aux noimes minimales d'habitation acceptables aux deux parties: 2° La Société du Québec assurera les services d'inspection de la construction ou de la transformation du projet; 3° La Société peut, en vertu d'ententes établies par les deux parties, examiner le projet de logement afin de s'assurer que le travail de construction ou de transformation a été effectué d'une fa(;ou raisonnablement conforme aux plans approuvés, au cahier des charges et aux normes de construction.7.Vérification: 1\" La Société du Québec doit soumettre un état dûment certifié indiquant le coût dc la construction ou de l'acquisition et dc la transformation du projet dès qu'il est parachevé; 2* I.a Société du Québec s'entendra avec la Société afin de permettre l'examen de tous les filtre-, dossiers et comptes se rapportant au projet, aux fins d'en vérifier le coût.».Défaut: 1° Dans l'éventualité d'un défaut de payer tout versement d'argent exigible en vertu de la présente convention, ou sur infraction ft toute stipulation ou entente qui y est contenue après one la totalité ou une partie dc tout prêt aura été avancée en vertu dc la présente convention, sujet cependant à ce que la Société donne à la Société du Québec un avis dc remédier le défaut ou l'infraction dans un délai dc trente (30) jours, je solde entier du capital de ce prêt ainsi que l'intérêt sur icelui, alors impayés, deviendront, au choix de la Société, immédiatement dûs et exigibles; 2° Dans l'éventualité ou le projet cesserait d'être un projet de logement tel que défini à l'article 53B (b) de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, le solde entier du capital dc ce prêt ainsi que l'intérêt sur icelui, alors impayés, deviendront, au choix de la Société, immédiatement dûs et exigibles.9.Prescription de la convention: Si une demande de déclaration d'admissibilité P°ur un projet désigné à l'annexe « A » n'a pas été reçue le 31 mars 1969, le projet ne sera pas admissible à un prêt en vertu de la présente convention.riod not exceeding 50 years when the full lance of principal and interest shall become due and be paid ; 4.The Québec Corporation shall have the privilege at any time before the expiry date of the said period of paying the whole or any part of any loan outstanding without notice or bonus.5.Security: On July 1st in each year, the Québec Corporation agrees to deliver to the Corporation debentures, in a form acceptable to both parties, equal in principal amount to the principal advanced on each loan fully disbursed.The Québec Corporation's obligation pursuant to the agreement to repay each loan together with interest thereon shall, upon delivery of each debenture, be deemed to be substituted by the obligation to repay each debenture in accordance with the terms thereof.6.Inspections: 1.The project will conform with minimum housing staudars acceptable to both parties; 2.The Québec Corporation will provide inspections of construction or conversion of the project; 3.The Corporation may under arrangement agreed upon by both parties inspect the housing project to ensure that the work of construction or conversion has been carried out in reasonable conformity with the approved plans, specifications, and standards of construction.7.Audit: 1.The Québec Corporation must, as soon as the project is completed, submit a duly certified statement of cost of construction or acquisition and conversion of the project; 2.The Québec Corporation will make arrangements with the Corporation to permit examination of all books, records, and accounts maintained in respect of tlie project for the purpose of verifying the cost Uiereof.8.Default: 1.In the event of default in the payment of any instalment of any monies payable hereunder, or upon breach of any covenant of agreement herein contained, after all or part of any loan hereunder has been advanced, subject however to notice by the Corporation to the Québec Corporation to remedy the default or breach within thirty (30) days, the whole of the principal together with the interest thereon remaining unpaid on that loan, sliall at the option of the Corporation forthwith become due and payable; 2.In the event the project is not maintained as a public housing project as defined in section 35B (b) of the National Housing Act, 1954, the whole of tlie principal together with the interest thereon remaining unpaid on that loan at the option of the Corporation shall forthwith become due and payable.9.Limitation of agreement: If an application for a declaration of eligibility on a project listed in Schedule \"A\" is not received by March 31st, 1969, the project will not be eligible for a loan under this agreement. 3274 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100- année, n' U 10.Projets additionnels: Sous réserve île l'approbation du gouverneur en conseil donnée en vertu des dispositions de l'article 35D de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation et sous réserve du respect dc toutes les autres conditions de la présente convention, la Société consent à examiner les demandes de la Société du Québec, au cours dc la période se terminant le 31 mars 1969, en vue d'obtenir des prêts à des fins de construction ou d'acquisition et de transformation de projets de logement en outre de ceux à l'annexe Ad, s'ils sont admissibles, à émettre une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt.12.Conservation des documents: Tous les documents, pièces justificatives, dossiers et comptes se rapportant nu coût de la construction ou de l'ucquisition et dc lu transformation du projet seront conservés pendant au moins sept (7) ans a compter de la date dc parachèvement du projet.Signé à Montréal, ce 17e jour dc mai 1968.La Société centrale d'hypothèques et de logement.Le président, H.W.Hionett.W.B.Scott.Le témoin, Alain de C.Nantkl.La Société d'habitation du Québec.Le président, Henri Dion.Le secrétaire, Conrad Delisle.Le témoin.Id un n ru i: Lai-lante.10.Additional projects: Subject to the approval of the Governor-iii.Council given pursuant to section 35D of the National Housing Act, 1954, and on compliance with all other terms and conditions of this agreement, the Corporation agrees to review application* by the Québec Corporation during the period ending March 31st, 1969, for loans fur the construction or acquisition and conversion of housing projects in addition to those listed in the attached Schedule \"A\" and if eligible, issue a declaration of eligibility and an estimate of loan amount.12.Retention of documents: All documents, vouchers, records and account* pertaining to the cost of construction or acquisition and conversion of a project will be retained for not less than seven years from the dale ol completion of that project.Signed at Montréal, that 17th day of May 1968, Central Mortgage and Housing Corporal ion.H.W.Higneti.President.W.E.Scott.Alain de C.Nantei., Witness.Québec Housing Corporation.Henri Dion, President, Conrad Dklisle.Secretary.Rodolphe Laplanti.Witness.Municipalité Municipality Cap-Chat Québec Montmagny Thetford Alines Rivière-du-Loup Trois-Rivières Daveluyvillc Montréal Greenfield Park I/ongueuil Sainte-Annc-de-Bcllcv Westmount Hull Cédule « A » \u2014 Schedule \"A\" Programmes municipaux d'habitation 1968-1909 Municipal housing programs 1968-1969 Capacité (logements) Prêt S.C.II.L Capacity CM.U.C.loan (housing units) 01 Région administrative du Bas St-Lourent- Gospésie 01 Lower St-Lawrcnce - Gaspé Administrative Region 25 S 240.000 OU 03 Région administrative de Québec 03 Québec Administrative Region 300 $ 5.100.01 ni IH) 20 270.001100 50 675.01 hi 00 50 075.001100 04 Région administrative des Trois-Rivières 04 Trois-Rivières Administrative Region 100 $ 1,375.000.00 25 246,000.00 06 Région administrative de Montréal 06 Montréal Administrative Region 1300 l21.fiCO.0tHI.ll0 50 300.000 00 100 1,400.000 00 ue 25 315,000.00 30 460,000 00 07 Région administrative de l'Outaouais 07 Outaouais Administrative Region 100 S 1,440,000 00 $34.056.000 00 Total: 2155 24946-0 249160 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.2k 3275 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1599 Québec, le 28 mai 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du titre III (Industrie du verre plat) du décret relatif à l'industrie de la construction dans les districts judiciaires de Chicoutimi et Roberval.II.esi ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: Que, conformément aux dispositions de la Loi îles décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec 1964, chapitre 143), le titre III (Industrie du verre plat) du décret numéro ]74;i du 11 juillet 1941 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans les districts judiciaires de Chicoutimi et Roberval, soit prolongé jusqu'au 31 août 1968.Le greffier du Conseil exécutif, 240 l7-o Jacques Prémont.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1339 Québec, le 1er mai 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant un accord entre la Société d'habitation du Québec et la Société Centrale d'Hypothèques et dc Logement pour le financement de programmes d'habitation pour étudiants.Attendu qu'en vertu de l'article 71 de la loi de la Société d'habitation du Québec (15-16 Elizabeth II.chapitre 55), la Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure tout accord avec le gouvernement du Cunndu ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu que la Société d'habitation du Québec et la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement, organisme du gouvernement du Canada, se sont entendues sur un accord, dont les ternies et conditions sont subtantiellemcnt conformes au texte reproduit en annexe « A » ci-dessous, prévoyant le financement pour un montant estimé à $33,342,600 dc programmes d'habitation pour étudiants au cours de l'exercice financier 1908-69 et de tout autre programme d'habitation pour étudiants qui pourra, pendant le même exercice financier, être approuvé confor-mément ù la loi de la Société d'habitation du Quéliec; Attendu que la Société par sa résolution numéro 233 du 11 avril 1968, prie le lieutenant-gouverneur en conseil de l'autoriser à conclure ledil accord avec la Société Centrale d'Hypo-thèques et de Logement; II.est ordonné, sur la propostion de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui -suit: La Société d'Iiabitation du Québec est autorisée a conclure avec la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement un accord dont les termes et conditions seront substantiellement conformes au texte reproduit en annexe « A » ci-dessous, prévoyant le financement, au cours de l'exercice financier 1968-69, de 21 programmes d'habita- Order in Council Executive Council Chamber Number 1599 Québec, May 28, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the extension of title III (Flat Glass Industry) of the decree respecting the building trades in the judicial districts of Chicoutimi and Roberval.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), title HI (Flat Glass Industry) of Decree number 1743 of July 11, 1941, as amended (Building Trades in the judicial districts of Chicoutimi and Roberval), be extended until August 31, 1968.Jacques Prémont, 24947-0 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1339 Québec, May 1, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an agreement between the Québec Housing Corporation and the Central Mortgage and Housing Corporation for the financing of student housing programs.Whereas pursuant to section 71 of the Québec Housing Corporation Act (15-16 Elizabeth II, chapter 55), the Corporation may, with the authorization of the Lieutenant-Governor in Council, enter into any agreement with the Government of Canada or with any body thereof, to facilitate the carrying out of that Act; Whereas the Québec Housing Corporation and the Central Mortgage and Housing Corporation, a body of the Government of Canada, liave entered into an agreement, the terms and conditions of which conform substantially with the text reproduced below in Annex \"A\", providing for the financing of an estimated $33,342,600 for student housing programs during the 1968-69 fiscal year, and of any other student housing program which may, during the same fiscal year, be approved pursuant to the Québec Housing Corporation Act; Whereas the Corporation, by its resolution number 233, bearing date the 11th day of April, 1968, requests the Lieutenant-Governor in Council to authorize its entry into the said agreement with the Central Mortgage and Housing Corporation; It is ordered, upon the recommendation of the Minister of Municipal Affairs, that: The Québec Housing Corporation is authorized to enter into an agreement with the Central Mortgage and Housing Corporation, the terms and conditions of which conform substantially to the text reproduced below in Annex \"A\", providing for the financing, during the 1968-69 fiscal year, of 21 student housing programs for an 3276 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° êA tion pour étudiants pour un montant estimé à $33,342,600 et le financement de tout autre programme d'habitation pour étudiants qui jxHirra pendant le même exercice financier, être approuvé conformément à la loi de la Société d'Iiabitation du Québec.Copie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, D.Tanguay.Convention passée en triplicate ce 17e jour de mai 1968; entre La Société Centrale d'Hypothéqué et de Logement, (ci-après appelée «la Socié'é»), d'une part, Et, La Société d'habitation du Québec, (ci-après appelée « la Société du Québec »), d'autre part, Attendu que la Société peut, en vertu des dispositions de l'article 36B de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, effectuer des prêts à une province, à des fins de construction ou d'acquisition et de transformation de projets de logement pour étudiants; Et attendu que la Société du Québec, en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi dc la Société d'habitation du Québec, est désignée comme un agent de la Couronne du chef de la province dc Québec; Et attendu que la Société du Québec peut, en vertu des dispositions de l'article 71 de la Loi dc la Société d'habitation du Québec, conclure tout accord avec le Gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci afin de faciliter l'exécution de cette loi ; Et attendu que par l'arrêté en conseil no 1339, daté du 1er jour de mai 1968, le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé la Société du Québec à conclure avec la Société un accord dont les conditions, en substance, sont celles dc la présente convention ; Et attendu que par le décret CP.1968-761, daté du 25e jour d'avril 1968, adapté selon les dispositions dc l'article 36B de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, le gouverneur en conseil a autorisé la Société à conclure la présente convention en vue de prêter une somme totale n'excédant pas $33,342,600 aux fins dc permettre il la Société du Québec d'entreprendre les projets de logement pour étudiants décrits à l'annexe « A » des présentes, chaque projet de logement ci-après mentionné devant être appelé « le projet » ; En conséquence, la présente convention fait foi des ententes suivantes entre les parties: 1.Prêt 1° Pourvu que la Société ait reconnu, selon l'article 36B de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, l'admissibilité au financement de chaque projet de logement désigné à l'annexe « A », la Société convient par les présentes d'avancer à la Société du Québec, en tenant compte de la limite imposée par le paragraphe 1 (5) de la présente convention, une somme totale n'excédant pas $33,342,600 et convient de débourser ladite somme pourvu que les conditions dc la présente convention aient été respectées; 2° La Société du Québec soumettra à la Société, à son bureau régional du Québec, 2350, chemin Manella, Ville Mont-Royal, en une forme acceptable aux deux parties, une demande de déclaration d'admissibilité et d'estimation du montant du prêt pour chaque projet; estimated $33,342,600 and the financing of any other student housing program which may during the same fiscal year, be approved, pursuant to the Québec Housing Corporation Act.' Certified copy.D.Tango ay, Acting Clerk of the Executive Council.This agreement made in triplicate the 17th day of May 1968; between: Central Mortgage and Housing Corporation, (hereinafter called \"the Corporation\"), of the first part: And, The Québec Housing Corporation (hereinafter called \"the Québec Corporation\"), of the second part: Whereas the Corporation may.pursuant to the provisions of section 36B of the National Housing Act, 1954, make loans to a province for the construction or acquisition and conversion of housing projects for students; And whereas the Québec Corporation, pursuant to section 4 of the Québec Housing Corporation Act, is designated as an agent of the Crown in Right the government of the Province of Québec; And whereas the Québec Corporation may.pursuant to section 71 of the Québec Housing Corporation Act make any agreement with the Government of Canada or anybody thereof to facilitate the carrying out of that Act; And whereas by Order-in-Council P.C.1339 dated the first day of May, 1968, the Lieutenant-Governor-in-Council has authorized the Quéliec Corporation to enter into an agreement substantially in the terms of this agreement with the Corporation; And whereas by Order-in-Council P.C.1968-761, dated tlie 25th day of April 1968, passed pursuant to section 36B of the National Housing Act, 1954, the Government-in-Council has authorized the Corporation to enter into this agreement to lend a total amount not exceeding $33,342,600 for the purpose of enabling the Québec Corporation to undertake the housing projects for students outlined in Schedule \"A hereto annexed, each housing project being hereinafter referred to as \"the project\"; Now therefore this agreement witnesseth that the parties hereto agree as follows: 1.Loan 1.Provided the Corporation has recognized the eligibility for the financing of each housing project listed in Schedule \"A\" under section 36B of the National Housing Act, 1951, the CoTpo-ration hereby agrees to advance to the Quebec Corporation, subject to the limitation imposed by section 1 (5) of this agreement, a total sum not exceeding $33,342,600 and undertakes to disburse the said sum provided the terms and conditions of this agreement have been complied with; 2.The Québec Corporation will submit to the Corporation at its Québec Regional Office, 2350 Manella Road, Town of Mount Royal an application in a form acceptable to both parties for a declaration of eligibility and for an estimute of the loan amount for each project; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.24 3277 3° Ln demande de déclaration d'admissibilité et d'estimation du montant du prêt pour chaque projet doit être accompagnée de plans, de devis descriptifs et de devis estimatifs des coûts du projet tel que requis par la Loi de la Société d'habitation du Québec; 4° Lu Société, dans les 21 jours suivant la réception dc ladite demande, émettra à la Société du Qlteboo à 1995, ouest, boul.Charest, Ste-Foy, Québec 10, une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt ou, dans le cas contraire, en informera par écrit la Société du Québec; 5° Il est convenu entre les parties que la déclaration d'admissibilité a pour seul but de déterminer que le projet peut faire l'objet d'un prêt en vertu de la Loi nationale sur l'Habitation et de fixer le montant du prêt; la Société du Québec est seule responsable de l'évaluation du besoin, de l'acceptation de l'emplacement et du nombre ainsi que de la grandeur des logements, de l'approbation de la planification de l'architecture, des plans et devis, des normes et conditions d'occupation et aucun certificat d'admissibilité ne sera refusé ou retenu pour des considérations basées sur ces sujets ou sur d'autres de même nature; 6° I.c montant du prêt pour chaque projet n'excédera pas 90% du coût réel du projet tel qu'accepté par les deux parties; 7° La Société du Québec peut, à même les sommes qui lui sont avancées pour un projet, effectuer un prêt à une municipalité, à un office municipal d'habitation, un hôpital, une corporation scolaire, une université, un collège, une a-\"riation coopérative ou un organisme sans but lucratif, aux fins de construire ou d'acquérir et de transformer le projet.2.doit du projet: La Société, aux fins d'établir le montant du prêt pour chaque projet, incluera comme partie OU coût réel du projet ce qui suit: o) Les sommes réellement et effectivement payees par la Société du Québec, une municipalité, un ollice municipal d'habitation, un hôpital, une cor|h>ration scolaire, une université, un collège, une association coopérative ou un organisme sans but lucratif, pour l'acquisition du terrain, la construction ou l'acquisition et la transformation du projet el l'exécution des travaux requis pour transformer chaque unité de logement du projet; li) Les sommes réellement et effectivement payées pour les matériaux utilisés lors de la transformation du projet lorsque lesdites sommes ne sont pas comprises dans le paragraphe « o > ci-dessus; ri Les sommes réellement et effectivement pavées pour l'aménagement du terrain, les travaux paysagers et pour l'installation ou la reparation d'aqueducs, égouts et autres services; d) Les sommes réellement déboursées pour services juridiques, taxes, permis de construction, honoraires et coûts des services d'architectes, d'arpenteurs, d'ingénieurs et autres; i L'intérêt payable jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; /) Les frais administratifs encourus par la Société du Québec en effectuant le prêt à l'une des corporations mentionnées au paragraphe 1 7) de cette convention, après entente entre les parties; g) Les primes payées par la Société du Québec, une des corporations mentionnées au paragraphe 3.The application for a declaration of eligibility and for an estimate of the loan amount for each project shall be accompanied by plans, specifications and a detailed estimate of costs for the project as required by the Québec Housing Corporation Act; 4.The Corporation will, within 21 days from the receipt of the application, issue to the Québec Corporation, at 1995 West, Charest Blvd., St.Foy, Québec 10, a declaration of eligibility and an estimate of the loan amount or, if otherwise, inform in writing the Québec Corporation; 5.It is agreed between the parties that the declaration of eligibility is for the sole purpose of recognizing that the project is eligible for a loan under the National Housing Act and determining the amount of each loan; the Québec Corporation has the exclusive responsibility of assessing the need for the project, of accepting the site, the number and size of units, of approving the planning, the architecture, tlie plans, the specifications, of determining the norms and conditions of occupancy and the Corporation agrees that a declaration of eligibility shall not be refused nor withheld for any consideration related to these or other matter of the same nature; 6.The amount of the loan for each project shall not exceed 90% of the actual cost of the project as accepted by both parlies ; 7.The Québec Corporation may, out of the moneys advanced to it for a project, make a loan to a municipality, municipal housing bureau, hospital, school corporation, university or college, co-operative association or non-profit corporation, for the construction or acquisition and conversion of the project.2.Cost of the project: The Corporation will, for the purpose of determining the amount of loon for each project, include as part of the actual cost of the project, the following: (a) Amounts actually and property paid by the Québec Corporation, a municipality, a municipal housing bureau, a hospital, a school corporation, a university a college, a co-operative association or a non-profit corporation, for the acquisition of land, the construction or the acquisition and conversion of the project and the performance of work required to convert each housing unit in the project; (6) Amounts actually and properly paid for materials used in the conversion of the project where such amounts are not included under 'a\" above; (c) Amounts actually and properly paid for landscaping and site improvements, and for installing or repairing water, sewer and other services; (d) Amounts actually paid for legal services, taxes, building permits and fees and costs for the services of architects, land surveyors, engi-ners and others; (e) Interest payable to the interest adjustment date; (/) The administration costs incurred by the Québec Corporation in making the loan to any of the corporations mentioned in section 1(7) hereinabove, as agreed upon between the parties; (17) Premiums paid by the Québec Corporation, or any of the corporations mentioned in section 3278 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 2L 1 (7) de cette convention ou un entrepreneur pour de l'assurance contre les pertes occassionnées par l'inccnilie ou d'autres risques, ayant trait au projet jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; h) Les coûts d'exploitation du projet moins les revenus bruts jusqu'à la date d'ajustement des intérêts; (') Tels autres coûts et sommes dont les parties peuvent convenir entre elles.3.Débours: 1° Lorsqu'une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt, relativement à un projet, ont été émises à la Société du Québec, la Société du Québec peut, à l'occasion, pendant la période de construction ou d'acquisition et de transformation du projet, demander à la Société un débours au compte du prêt pour toute partie du projet qui a été achevée; 2° Tout débours subséquent, au compte du prêt, jwur chaque projet peut être effectué mensuellement; 3° Une demande de débours relativement à un projet doit être accompagnée d'un certificat d'un officier autorisé de la Société du Québec établissant: a) la partie du projet qui a été achevée, et b) l'estimation du coût de la partie du projet qui a été achevée; 4° Sur réception d'une demande de débours au compte d'un prêt, la Société effectuera, aussitôt que possible, le débours à la Société du Québec d'une somme n'excédant pas 90% du coût réel du projet encouru à la date du débours, tel qu'accepté par les deux parties, moins le montant égal aux débours déjà effectués à la Société du Québec pour le projet.4.Remboursement: 1° Le montant du principal de chaque prêt doit être le montant du prêt avancé à la Société du Québec pour le projet; le taux d'intérêt sur chaque prêt doit être le taux d'intérêt approuvé par le gouverneur en conseil et en vigueur à la date de l'émission de la déclaration d'admissibilité: 2° Chaque prêt, effectué par la Société du Québec à l'une des corporations mentionnées au paragraphe 1 (7) de cette convention à même les sommes qui lui sont avancées en vertu de la présente convention pour la construction ou l'acquisition et la transformation du projet, doit porter intérêt au même taux que celui qui est stipulé dans la déclaration d'admissibilité pour ce projet; 3° L'intérêt sur chaque prêt doit être calculé semestriellement, non à l'avance, aussi bien après qu'avant l'échéance, jusqu'au remboursement du prêt: l'intérêt doit être impute sur les sommes avancées à l'occasion et calculé ù compter des dates respectives de ces avances jusqu'au 1er jour de juillet suivant la date de parachèvement du projet (appelée dans la présente convention «la date d'ajustement des intérêts»); ledit intérêt deviendra alors dû et devra être payé comptant ou par chèque, et par la suite, le montant du capital dc chaque prêt ainsi que l'intérêt sur icelui au taux susdit deviendra dû et devra être payé annuellement en versements combinés égaux le 1er jour de juillet de toutes et chacune des années pendant une période n'excédant pas 50 ans; le solde entier du capital et de l'intérêt deviendra alors dû et devra être payé; 1 (7) hereinabove or the contractor for insurance against loss by fire or other perils in respect of the project to the interest adjustment date; (/ar l'engagement de les rembourser en conformité avec les conditions d'icellcs.0.Inspection»: I Le projet sera confoime aux normes minimales d'habitation acceptables aux deux parties: 2\" La Société du Québec assurera les services d'inspection de la construction ou de la transformation des projets; 3 La Société peut, en vertu d'ententes établies pnr les deux parties, examiner le projet dc logement afin de s'assurer que le travail dc construction ou de transformation a été effectué d'une façon raisonnablement conforme aux plans approuvés, au cahier des charges, et aux normes de construction.7.Vérification: 1° La Société du Québec doit soumettre un étal dûment certifié du coût de la construction ou de l'acquisition et de la transformation du projet dès qu'il est parachevé; 2° La Société du Québec s'entendra avec la Société afin de permettre l'examen de tous les live-, dossiers et comptes se rapportant au projet, aux fins d'en vérifier le coût.S.Défaut: 1 Dans l'éventualité d'un défaut de payer tout versement d'argent exigible en vertu de la présente convention, ou sur infraction à toute Stipulation ou entente qui y est contenue, après que la totalité ou une partie dc tout prêt aura été avancée en vertu de la présente convention, sujet cependant à ce que la Société donne a la Société du Québec un avis dc remédier le défaut ou l'infraction dans un délai de trente (30) jours, le solde entier du capital dc ce prêt ainsi que l'intérêt sur icelui alors impayés, deviendront, au choix de la Société, immédiatement dus et exigibles; 2* Dans l'éventualité où le projet cesserait d'être un projet de logement tel que défini a l'article 36B de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, le solde entier du capital de ce prêt ainsi que l'intérêt sur icelui, alors impayés, deviendront, au choix de la Société, immédiatement dus et exigibles.9, Prescription de la convention: Si une demande de déclaration d'admissibilité pour un projet désigné à l'annexe « A » n'a pas été reçue le 31 mars 1969, le projet ne sera pas admissible à un prêt en vertu de la présente convention.10.Projets additionnels: Sous réserve de l'approbation du gouverneur eu conseil donnée en vertu des dispositions de l'article 36B de la Loi nationale de 1954 sur l'ha- 4.The Québec Corporation shall have the privilege at any time before the expiry date of die said period of paying the whole or any part of any loan outstanding without notice or bonus.5.Security: On July 1st in each year, the Québec Corporation agrees to deliver to the Corporation debentures, in a form acceptable to both parties, equal in principal amount to the principal advanced on each loan fully disbursed.The Québec Corporation's obligation to repay each loan together with interest thereon shall, upon delivery of each debenture, be deemed to be substituted by the obligation to repay each debenture in accordance with the terms thereof.6.Inspections: 1.The project will conform with minimum housing standars acceptable to both parties; 2.The Québec Corporation will provide inspections of construction or conversion of the projects; 3.The Corporation may undcx.arrangements agreed upon by both parties inspect the housing project to ensure tliat the work of construction or conversion has been carried out in reasonable conformity with the approved plans, specifications, and standards of construction.7.Audit: 1.The Québec Corporation must, as soon as the project is completed, submit a duly certified statement of cost of construction or acquisition and conversion of the project; 2.The Québec Corporation will make arrangements with the Corporation to permit examination of all books, records, and accounts maintained in respect of the project for the purpose of verifying the cost thereof.8.Default: 1.Li the event of defuult in the payment of any instalment of any monies payable hereunder, or upon breach of any covenant or agreement herein contained, after all or part of any loan hereunder lias been advanced, subject however to notice by the Corporation to the Québec Corporation to remedy the default or breach within tlurty (30) days, the whole of the principal together with the interest thereon remaining unpaid on that loan, shall at the option of the Corporation forthwith become due and payable; 2.In tlie event the project is not maintained as a housing project within the terms of section 36B of the National Housing Act, 1954, the whole of the principal together with the interest thereon remaining unpaid on that loan shall at tlie option of the Corporation forthwith become due and payable.9.Limitation of agreement: If an application for a declaration of eligibility on a project listed in Schedule \"A\" is not received by March 31st, 1969, the project will not be eligible for a loan under this agreement.10.Additional projects: Subject to the approval of the Governor-in-Council given pursuant to section 36B of the National Housing Act, 1954, and on compliance 3280 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n\" SA bitation et sous réserve du respect de toutes les autres conditions dc la présente convention, la Société consent ft examiner les demandes de la Société du Québec, au cours de la période se terminant le 31 mars 1969, en vue d'obtenir des prêts à des fins de construction ou d'acquisition et de transformation de projets de logement en outre de ceux désignés à l'annexe « A > et, s'ils sont admissibles, à émettre une déclaration d'admissibilité et une estimation du montant du prêt.12.Conservation des documents: Tous les documents, pièces justificatives, dossiers et comptes se rapportant au coût de la construction ou dc l'acquisition et de la transformation du projet seront conservés pendant au moins sept ans à compter de la date de parachèvement du projet.Signé à Montréal, ce 17e jour dc mai 1968.La Société centrale d'hypothèques et de logement.Le président, H.W.HlCiNETT.W.E.Scott.Le témoin, Alain de C.Nantel.La Société d'habitation du Québec.Le président, Henri Dion.Le secrétaire, Conrad Dllisle.Le témoin, Rodolphe Laplante.with all other terms and conditions of this agreement, the Corporation agrees to review applications by the Québec Corporation during the period ending March 31st, 1969, for loans for the construction or acquisition or acquisition and conversion of housing projects in addition to those listed in the attached Schedule \"A\" and, if eligible, issue a declaration of eligibility and an estimate of the loan amount.12.Retention of documents: All documents, vouchers, records and accounts pertaining to the cost of construction or acquisition and conversion of a project will be retained for not less than seven years from the date of completion of that project.Signed at Montréal, that 17th day of May 1068.Central Mortgage and Housing Corporation.H.W.HlGNETT, President, W.E.Scott.Alain de C.Nantel, Witness, Québec Housing Corporation.Henri Dion.President.Conrad Delislk.Secretary.Rodolphe Laplante, Witness.Cedi'le « A » \u2014 Schedule \"A\" Municipalité Municipality Rimouski Gaspé Gaspé Rimouski Matane Matanc Jonquièrc Sainte-Foy Sainte-Foy Trois-Rivières Programmes d'habitation pour étudiants 1908-1969 Housing programs for students 1968-1969 Organisme Borrower Capacité (lits) Capacity (beds) 01 Région administrative du Bas St-Laurcnt - Gaspésic 01 Lower St-Lawrencc - Gaspé Administrative Region C.E.G.E.P.Commission scolaire Commission scolaire Commission scolaire Commission scolaire Commission scolaire 800 400 95 850 200 150 02 Région administrative du Sagucnay - Lac St-Jean 02 Saguenay - Lac St-Jcan Administrative Region C.E.G.E.P.200 03 Région administrative dc Québec 03 Québec Administrative Region Université Laval Université Laval 200 1000 04 Région administrative des Trois-Rivières 04 Trois-Rivières Administrative Region Prêt S.C.II.L CM.U.C.han $ 3.240.000.00 1,270.000 00 370.000 IK) 2.850.000 00 820.000.110 550,000 00 900,000 $ 845.000.1 4,320,000 l C.E.G.E.P.200 810,000.00 05 Région administrative des Cantons-dc-l'Est 05 Eastern Township Administrative Region Ascot Université de Sherbrooke 600 $ 2,592,000,00 Ascot Université de Sherbrooke Cafétéria (1000 étud.) 720,000 'i| Ascot-Nord Université de Sherbrooke 150 657,000.00 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 1968, Vol.100, No.2i 3281 Cédule « A » \u2014 Schedule \"A\" Programmes d'habitation pour étudiants 19C8-19G9 Housing programs for students 1968-1969 (suite) \u2014 (continued) Municipalité Municipality Montréal Sninte-Anne-ilr-licllcvue Montréal Mont real Montréal Brouiont Montréal Hull Organisme Borrower Capacité (lits) Capacity (beds) 06 Région administrative de Montréal 06 Montréal Administrative Region Université de Montréal Université McGill Mount-Royal student Residence Association.C.E.G.E.P.Maisonneuve C.E.G.E.P.Ahuntsic Institut des Sciences Commerciales.Hôpital Notre-Dame 750 500 58 Cafétéria (400 étud.) Cafétéria (600 étud.) 60 300 Bouyo Havre St-Pierrc 24916-0 07 Région administrative de l'Outaouais 07 Outaouais Administrative Region C.E.G.E.P.400 08 Région administrative de Nord-Ouest 08 North West Administrative Region C.E.G.E.P.500 09 Région administrative de la Côte-Nord 09 Côte-Nord Administrative Region Commission scolaire Total: 316 9729 Prêt S.C.II.L.C.M.U.C.loan S 3.425,000.00 2,317,700.00 207,900.00 288,000.00 300,000.00 420,000.00 2,100,000.00 S 1,755,000.00 S 2,250,000.00 S 1,275,000.00 $33,342.000 00 24946-0 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1707 Québec, le 6 juin 1968.Pré-rnt: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Conceunant des modifications au décret relatif à l'industrie du bois ouvré dans la région de Québec.ArtENDU que, conformément aux dispositions île la Loi des décrets de convention collective (si.,iuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 20s 1 du 28 septembre 1967 et amendement, relatif à l'industrie du bois ouvré dans la région \u2022le Québec, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; AvBBNdu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition du 13 avril 1968; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition dc l'honorable ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2684, soit modifié comme suit: Order in Council Executive Council Chamber Number 1707 Québec, June 6, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree respecting the Woodworking Industry in the Québec region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Woodworking Industry in the Québec region (made binding by Decree number 2684 of September 28, 1967, as amended) liave petioncd the Minister of Labour to submit certain amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision; Whereas the petition was published in the Québec Official Gazette of April 13, 1967; Whereas, in compliance with the Act, the objection brought forth was duly considered; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That said Decree number 2684 be amended as follows: 3282 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n\" 2L 1° A l'article IV (T 'aux dc salaires minimaux), le taux du salaire suivant est ajouté après ceux des apprentis: « Étudiant.SI .00 l'heure.» 2° Â l'article V (Dispositions spéciales), le nouveau paragraphe « g » suivant est ajouté: « g) Étudiants: Un employeur peut engager des étudiants pour la période des vacances, soit du 15 niai au 1er octobre, mais cela ne doit pas être l'occasion de licenciements.De plus, le nombre d'engagements d'étudiants ne doit pas dépasser dix pour cent (10%) dc l'effectif total des salariés de l'entreprise assujettie au présent décret.» I.e greffier suppléant du Conseil exécutif, 24947-0 Don at Tanc.uay.1.The following wage rale is added after that of apprentices in section IV (Minimum wage rates): \"Student.$1.00 an hour.\" 2.The following new subsection \"g\" is added to section V (Sjiecial provisions) : \"(g) Students: Students may be hired during I lie vacation period (May 15th to October 1st), Hiring of students shall not entail lay-offs, The number of students hired shall not exceed In',' of the total number of employees in the firm subject to this decree.\" Don at T/ANG0AV, 24947 Acting Clerk of the Executive Council.Ministère du Travail Department of Labour Avis dc modification Industrie de l'ascenseur \u2014 Province lx ministre du Travail, l'honorable Maurice Bellcmare, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (SI al ut s refondus de Québec, 1964, chapitre 113), de son intention de soumettre ù l'appréciation et à la decision du lieutenant-gouverneur en conseil une modification à l'arrêté en conseil numéro 48 (U) du 18 janvier 1950 el.amendements, relatif à l'industrie des ascenseurs et concernant tous les décrets régissant l'industrie et les métier-, de la const ruction dans la province; Les taux de salaires pour In région dc Montréal seront remplacés par les suivants: T aux horaires m in ima Mécanicien Aide 'Région de Montréal: comprenant tout, le territoire situé entre la région de Hull et lu région dc Québec.$4.42 $3.09» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendements.L'arrêté en conseil entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Quéliec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle de Québec, l'honorable ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre adjoint du Traçait, RÉAL MlHI.AI'LT.Ministère du Travail.Québec le 15 juin 1908.24947-0 Notice of Amendment Elevator Industry \u2014\u2022 Province Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (HSQ 1904.c.143), the Honourable Maurice Bellemare, Minister of Labour, hereby gives notice that he intends submitting the following amendment to Order in Council number IS (II) of January 18, I 156 and amendments (concerning all the decrees governing the Construction industry and trades in the Province), to the consideration and decision of the Lieutenant-Governor in Council: Wage rates for the Montréal region will he replaced I.y the following: Minimum hourly rates Mechanic Helper \"Montréal region: including the entire territory lying between the Hull region and the Québec region.$4.12 S3 09\" Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an Order in Council, which comes into force on the date of its publication in the Québec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quéliec.Official Gazette, the Honourable Minister of Labour will consider objections which interested parties may wish to make.RÉAI.MlREAULT, Assistant Deputy Minister of Labour.Department of Labour, Québec, June 15, 1968.219!7-o Chartes \u2014- Abandon de Charters \u2014 Surrender of Fer Ornemental Windsor inc.Prenez avis que la compagnie « Fer Ornemental Windsor inc.», ayant son siège social à Windsor Mills, comté dc Richmond, demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte, conformément a la Loi des compagnies.Sherbrooke, ce 4ième jour de juin 1968.Les procureurs dc la compagnie, 24969-0 O'Bukahy & Gknkst.Fer Ornemental Windsor inc.Notice is hereby given tliat \"Fer Ornement Windsor inc.\".having its head ollice in the Ci of Windsor Mills, county of Richmond, w apply to the Provincial Secretary of the Provii of Québec, for leave to surrender its chart under the provisions of the Companies Act.Sherbrooke, this 4th day of June 1908.O'Bkeaiiy & Genest.24969-0 Attorneys for the Com pan y QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 196S, Vol.100, No.SI 32S3 An! i-ltoiiillc AutO ltéc Pi cncz avis que la compagnie « Anti-Rouillc Auto Itée », demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire, 24955-0 Paul-André Adam.By wood Realty Co.Prenez avis que la compagnie « Bywood Realty Co.», ayant son siège social ù Montréal, demandera au secrétaire de ia province la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 15c jour de mai 1908.Le secrétaire, 24956-0 (signé) Ben Z.Goldstein.Carillon Realties Corp.Avis est donné que la compagnie « Carillon Realties Corp.», une compagnie constituée en vertu de In Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, Québec, s'adressera au secrétaire de la province dc Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 31e jour de mai 1968.Les procureurs de la compagnie, Kaufman, Hoffman, 24957 Respitz & Sederoff.I ladley Investment Corporation Avis est donné que « Had Icy Investment Conjuration », une coriioration constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social et sa principal place d'affaires en les ville et district de Montréal, s'adressera au secrétaire dc la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 4c jour de juin 1968.Les procureurs des requérants, Ciiait, Aronovttch, Salomon, 24958 Gelber, Reis & Bronstein.Anti-Rouille Auto Itée Notice is hereby given that the company \"Anti-Rouille Auto Itée\", will apply to the secretary of the province for leave to surrender its charter.Paul-André Adam, 24955-0 Secretary.Bywood Realty Co.Notice is hereby given that \"Bywood Realty Co.\", having its head office at Montreal will apply to the Provincial Secretary for permission to surrender its charter under the provisions of tlie Companies Act.Montréal, the 15th day of May, 1968.(signed) Ben Z.Goldstein, 24956-0 Secretary.Carillon Realties Corp.Take notice tliat \"Carillon Realties Corp.\", a company incorporated under tlie Companies' Act, and having its head office at Montreal, Quebec, will apply to the secretary of the province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies' Act.Dated at Montréal, this 31st day of May, 1968.Kaufman, Hoffman, Respitz & Sederoff, 24957-0 Attorneys for company.Hadlcy Investment Corporation Notice is hereby given that \"Hadley Investment Corporation\", a corporation constituted under the Companies' Act and liaving its head ollice and principal place of business in the city and district of Montréal, will apply to the Provincial Secretary of the province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies' Act.Dated at Montréal, this 4th day of June, 1968.Chait, Aronovitcii, Salomon, Gelber, Reis & Bronstein, 24958-0 Attorneys for applicants.labrosse Construction Investments Ltd.< Labrosse Construction Investments Ltd.», donne avis par les présentes en vertu de lu Loi des compagnies qu'elle demandera au secrétaire de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 4e jour du mois de juin 1968.Le secrétaire-trésorier, 24959-0 R.G.Forster.Dano Development Inc.Prenez avis que la compagnie « Dano Development Inc.», demandera au secrétaire de la province, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur, 24G0S-O L.R.Z.Kos.Leblond & Fils inc.Prenez avis que la compagnie * Leblond & Pils inc.», demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire, 24960-o Me Paul-André Adam.Labrosse Construction Investments Ltd.\"Labrosse Construction Investments Ltd.\", hereby gives notice under the Companies Act that it will apply to the secretary of the province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Montréal, this 4th day of June 1968.R.G.Forster, 24959-o Secretary-Treasurer.Dano Development Inc.Take notice that the company \"Dano Development Inc.\", will apply to the Secretary of the Province, for leave to surrender its charter.L.R.Z.Kos, 24968-0 Attorney.Leblond & Fils inc.Notice is hereby given that the company \"Leblond & Fils inc.\", will apply to the secretary of the province for leave to surrender its charter.Me Paul-André Adam, 24960-o Secretary. 3284 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 21 Nu Park Deluxe Delicatessen Inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Nu Park Deluxe Delicatessen Inc.», constituée en corporation en vertu de la Ix>i des compagnies et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera au secrétaire de la province de Québec pour obtenir l'autorisation d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Date à Montréal, ce 3e jour de juin 1968.Les procureurs de la requérante, 24961 Pollack & Pollack.Rodi Construction Ltd.Prenez avis que la compagnie < Rodi Construction Ltd.», demandera au secrétaire dc la province, la permission d'abandonner sa charte.Le notaire, 24962-0 Me Dominic Manzo.Trans Island Properties Inc.Avis est donné que « Trans Island Properties Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au secrétaire dc la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 3e jour de juin 1968.Les procureurs de la requérante, 24963 Pollack & Pollack.Dal-Laur Land Holding Corp.Avis est donné par les présentes que la compagnie < Dal-Laur Land Holding Corp.», une corporation constituée en vertu «le la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, s'adressera au Secrétaire «le la province |x)ur obtenir la permission d'abandonner sa charte, en vertu des dispositions dc la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 10c jour de mai, 1968.Le président, 24967-0 Sidney Zoltak.Gatineau Sand & Gravel Ltd.Prenez avis que la compagnie < Gatineau Sand & Gravel Ltd.», demandera au secrétaire dc la province la permission d'abandonner sa charte.Gatineau, le 16 mai, 1968.Le procureur de la compagnie, 24970-o hi i.m Beaudhy, notaire.Philips Fuel Ltd.Prenez avis que la compagnie « Philips Fuel Ltd.», demandera au secrétaire de la province la permission d'abandonner sa charte.Gatineau, le 16 mai, 1968.Le procureur de la compagnie, 24971-0 Piekre Beaudry, notaire.Nu Park Deluxe DeUcatesscn Inc.Notice is hereby given that \"Nu Park Deluxe Delicatessen Inc.\", a corporation _ constituted under the Companies Act, and having its head office in tlie city of Montréal, will apply to the secretary of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montréal, this 3rd day of June.1968.Pollack & Pollack, 24961-o Attorneys for petitioner.Rodi Construction Ltd.Notice is hereby given that \"Rodi Construction Ltd.\", will apply to the Provincial Secretary for leave to surrender its charter.Me Dominic Manzo, 24962 Notary.Trans Island Properties Inc.Notice is hereby given that \"Trans Island Properties Inc.\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the secretary of the province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montréal, this 3rd day of June, 1968.Pollack & Pollack, 24963-0 Attorneys for petitioner.Dal-Laur Land Holding Corp.Notice is hereby given that \"Dal-Laur Land Holding Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montréal, will apply to the Provincial Secretary of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montréal, this 10th day of May.1968.Sidney Zoltak.24967-0 President.Gatineau Sand & Gravel Ltd.Take notice tliat the company \"Gatineau Sand & Gravel Ltd.\", will apply to the Secretary of the Province for leave to surrender its charter.Gatineau, this 16th of May, 1968.Pieriie Beauduy notary.24970-o Attorney for the Compaiui.Philips Fuel Ltd.Take notice that the company \"Philips Fuel Ltd.\",will apply to the Secretary of the Province for leave to surrender its charter.Gatineau, 16th May, 1968.Pierre Beaudry, notary, 24971-0 Attorney for the Company.Sièges sociaux Head Offices Guilhart Mfg.Co.Ltd.Guilhart Mfg.Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie < Guilhart Notice is given that \"Guilhart Mfg.Co.Ltd.\" Mfg.Co.Ltd.» a cliangé son siège social du lias transferred its head office from 1171 Cartier numéro 1171, rue Cartier, Trois-Rivières, au Street, Trois-Rivières, to 29 Roy Street, C'ap-de- numéro 29, rue Roy, Cap-dc-la-Madeleine.la-Madeleine.Le secrétaire, Jeanine Vioneault, Jeanine Vigneault, Secretary.24975-0 15161-61 24975-o 15161-61 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 19G8, Vol.10O, No.2k 3285 Lucien Bédard & Cie inc.Avis est donné que * Lucien Bédard & Cie inc.» a changé son siège social du numéro 822, rue Sherbrooke est, Montréal, au numéro 6, boulevard Desaulniers, St-Lambert.Le secrétaire, Yolande S.Bêdakd.24980-o 11722-55 Lucien Bédard & Cic inc.Notice is hereby given that \"Lucien Bédard & Cie inc.\" bas ciianged its head office from number 822, Sherbrooke Street, East, Montréal, to number 6, Desaulniers Boulevard, St-Lambert.Yolande S.Bédard, \u2022 Secretary.24980 11722-55 Lucien Bedard Maintenance Inc.Avis est donné que la compagnie « Lucien Dedard Maintenance Inc.» a changé son siège social du numéro 822, rue Sherbrooke est, Montréal, au numéro 6, boulevard Desaulniers, St-Limbert.Le secrétaire, Yolande S.Bédard.24981-0 1520-G7 Boivin et Filion inc.Avis est par les présentes donné que « Boivin et Filion inc.», une compagnie formée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes émises le 13 novembre 1967, a son principal bureau d'affaires à 75 rue Labelle, Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne, province de Quél>ec.Daté à Saint-Jérôme, ce 20 janvier 1968.(Sceau) Le secrétaire, 24982-0 Léo Boivin.Lucien Bedard Maintenance Inc.Notice is hereby given that \"Lucien Bedard Maintenance Inc.\", lias changed its head office from 822 Sherbrooke Street East, Montréal, to 6 Desaulniers Boulevard, St-Lambert.Yolande S.Bédard, Secretary.24981 1520-67 Boivin et Filion inc.Notice is hereby given tliat \"Boivin et Filion inc.\", a company formed under Part I of the Companies Act, by letters patent issued November 13.1967, has its principal business place at 75 Labclle Street, Saint-Jérôme, in the county of Terrebonne, province of Québec.Dated at Saint-Jérôme, this January 20, 1968.(Seal) Léo Boivin, 24982 Secretary.Commission des Loisirs de la Municipalité de St-Calixte Inc.Prenez avis que « Commission des Loisirs de la Municipalité de St-Calixtc Inc.», fut diuuent incorporée par lettres patentes émises sous la troisième partie tie la Loi des compagnies, le l.\"> février 1968 et que cette corporation a établi son siège social dans la province de Quélwc, à l'Hôtel de Ville, St-Calixte de Kilkenny, comté de Montcalm.St-Calixte, ce 23e jour d'avril 1968.Le président, Conrad Touciiette.249S3-0 617-68 M.B.M.B.Inc.Avis est donné que la compagnie « M.B.M.B.Inc.constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 mars 1968.et ayant son bureau principal à Montréal, a établi son bureau au 11515 rue James Morricc.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Montréal, ce 10 avril, 1968.Le président, Maurice Bélanger.24984-0 1282-68 Marché Julien inc.Avis est donné que la compagnie * Marché Julien inc.», constituée en corporation par let 1res patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 14 février 1968 et ayant son siège social en la cité et district de St-Maurice, a établi son bureau au 741 de la 6e avenue à Grand'Mère, district de St-Maurice dans la province de Québec.Daté à Grand'Mère, ce 9e jour de mai 1968.Le secrétaire, Claude Julien.24988-0 545-68 Commission des Loisirs de la Municipalité dc St-Calixte Inc.Take notice tliat \"Commission des Loisirs de la Municipalité de St-Calixte Inc.\", was duly incorporated by letters patent issued on February 15, 1968, under the provisions of Part HI of the Companies' Act and that it has since established its head office at Town Hall, St-Calixte de Kilkenny, county of Montcalm.St-Calixte, this 23rd day of April, 1968.Conrad Touchette, President.24983-0 617-68 M.B.M.B.Inc.Notice is hereby given that \"M.B.M.B.Inc.\", incorporated by letters patent dated March 21, 1968, and having its principal office in Montréal, has established its office at 11515 James Morrice Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Montréal, April.10, 1968.Maurice Bélanger, President.24984 1282-68 Marché Julien inc.Notice is hereby given that \"Marché Julien inc.\", incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the May 23, 1968, and having its head office in the city and district of St-Maurice, has established its office at 741, 6th avenue in Grand'Mère, district of St-Maurice, province of Québec.Dated at Grand'Mère, this 9th day of May 1968.Claude Julien, Secretary.24988-0 545-68 3286 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 19G8, 100' année, n\" SA Edita Inc.Avis est donné que la compagnie « Edita Inc.», constituée en corporation selon la première partie de la Loi des compagnies, en date du 21 mars 1068.et ayant son siège soeial dans le district «le Montréal, a établi son bureau au numéro 5055 Côte St-Luc, app.31, à Montréal.À compter de la «late du présent avis, le bureau est considéré par lu compagnie connue étant son siège social.Montré'ul, ce 30e jour d'avril 1908.Le président, Jean-Paul Dicas.Le secrétairc-trésorierc.Tiikiik.se Dic.as-McCutciieon.24985-0 890-68 Edita Inc.Notice is hereby given that \"Edita Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act on March 21.1908.and having its head office in the district of Montréal, has established its ollice at number 5055 Cote St-Luc.Apt.31.in Montréal.From and after the date of this notice the ollice is considered by the company as its head ollice.Montréal, this 30th ilay of April.1968.Jean-Paul Di:gas, President.Tiieiie.se Duoas-McCitciikov Secretary-Treasurer.24985 SIM-OS Granhy Finance Corporation Avis est donné que la compagnie « (iranby Finance Corporation » constituer en corporation par lettres patentes, première partie «le lu loi «les compagnies en date du 14 avril 1948.et ayant son bureau principal dans (iranby.comté dc Shelïord où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 237 de la rue Principale, l'a transporté au numéro 50 «le la rue Centre.A compter de la date «lu présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.(iranby, ce 3e jour «le mai 1908.Le secrétaire.A.1.BODIK.24980-o 3217-48 ( .n'm nu il Itée Avis est par les présentes donné que « G remont liée», constituée en corporation en vertu de la Loi «les compagnies par lettres patentes en date du 27 mars 1968 a son siège social à la Tour «le la Bourse.Place Victoria, 800 Square Victoria, suite 2004.Montréal.Montréal, 14 mai 1908.Le président, Leon m>as Lagies.24987-0 1405-68 Paramount Specialties Ltd.Avis est donné que la compagnie « Paramount Specialties Ltd ».constituée en corixirution par lettres patentes datées du 5 février 1908 a son bureau chef au numéro 460 de la rue St-Jacques, à Ville St-Pierre, district de Montréal.À compter «le la date dc cet avis, ledit bureau est considéré comme étant le bureau chef.Donné à Ville St-Pierre, ce 23j jour de mai 1968.24989-o J.P.VoiZARD.G ran by Finance Corporation Notice is hereby given that \"(iranby Finance Corporation'' incorporated by letters patent, Part of the Com|Minics Act, dated April.14 1948.and having its head oltice in (iranby.county of Shelford where its office was situated up to to-day at number 237 Main Street, has moved it to number 50 Centre Street.From and after the dute of the present notice, the said ollice is considered by the company, us being its head office.Granby.this 3rd .lay of May 1968.A.J.BOCIN.Secrelari/.24986 3217-4$ Grcmont liée Notice is hereby given that \"(iremont liée\", incorporated under the Coin|ianies Act by letters jiatciit dateil March 27.1968.has its head ollice at Tour «le la Bourse.Place Victoria, 800 Victoria Square, Suite 2604.Montréal.Montréal.May 14, 1968.Leoviiias Lagiks.President.24987 1405-68 Paramount Specialties Ltd.Notice is hereby given that \"Punimoiiiit Specialties Ltd.\", ineoriioratcd by letters patent bearing date the February 5.1908.has Its III ad ollice at number 460 St.James St.in Ville St-Pierre, district of Montréal.As from the date of this notice, the said ollice is considered as being its lieuil ollice.Given at Ville St-Picrrc.this 23rd day of May.1968.24989 J.P.VoilAHD.Société Jan-Mar inc.Avis est donné que la compagnie « Société Jan-Mar inc.», constituée en corporation en vertu «le lu première partie «le la Loi des compagnies en «late «lu 8 avril 1968.et ayant son bureau principal à I.aprairie, a établi son bureau au 115, Chemin St-Jean.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 10e jour d'avril 1968.Le président, Marcel Guérin.24990-o 1589-68 Société Jan-Mar inc.Notice is hereby given that \"Société Jan-Mat inc.\".incorporated under Part I of the Companies Act.«lated April 8.1968.and having it-princiiial office at Laprairie, has established its ollice at 115 St-Jean Iload.From and after the «late of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.(liven at Montréal, this 10th day of April, 1968.Marcel Gueiiin.President.24990 158908 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 19GS, Vol.100, No.21 8287 Associations coopératives Cooperative Associations Association coopérative Association coopérative de consommation Airo de consommation Airo (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative < Association coopérative de consommation Airo .Le siège social de cette association coopérative est situe à Bagolvillc, Québec, duns le district électoral de Dubuc.Québec, le 31 mai 1968.Le sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 24949-0 Louis-Philippe Bouchard.(Cooperative Association Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial institutions, companies and cooperatives has authorized the formation of the cooperative association \"Association cooperative de consommation Airo\".The head oflice of the co-operative association is located at Bagotvillc, Québec, in the electoral district of Dubuc.Québec, May 31.1968.Louis-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial institutions, 24949 companies and co-operatives.Association coopérative de consommation es employés civils (Service des pénitenciers, région du Québec) (Loi des associations coopératives) Avl est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé lu formation de l'association coopérative «Association coopérative de consommation «les employés civils (Service des pénitenciers, région du Québec) ».Le siège social «le cette association coopérative est \u2022iluéà 5486, Boulevard Lévesque, St-Vincent de l'aul, Québec, dans le district électoral dc Laval.Québec, le 31 mai 1968.ht sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 2I9.10-o Louis-Philippe Bouchard.Association coopérative étudiante du collège St-Romuald (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, u approuvé la formation de l'association coopérative 4 Association coopérative étudiante du collège St-Itomuald ».Le siège social de cette association coopérative est situé à 650.rue Vumasku.Furnham, Québec, dans le district électoral «le Missisquoi.Quelle, le 4 juin 1968.Le sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 24953-0 Louis-Philippe Bouchard.Association coopérative dc consommation des employés civils (Service des pénitenciers, région du Québec) (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved the formation of the cooperative association \"Association coopérative «le consommation des employés civils (Service des pénitenciers, région du Québec)\".The head office of this cooperative association is situated at 5486 Lévesque Boulevard, St-Vincent de Puul, Québec, in the electoral district of Laval.Québec, May 31.1968.Louis-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial institutions, 24950 companies and co-operatives.Association coopérative étudiante du collège St-Romuald (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given tliat the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative approved the formation of the cooperative association \"Association coopérative étudiante du collège St-Romuald\".The head office of this cooperative association is situated at 650 Yamaska Street, Furnliam, Québec, in the electoral district of Missisquoi.Québec, June 4.1968.Louis-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial institutions, 24953 companies and co-operatives.Association coopérative de St-Méthodc (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le secrétaire dc la province a approuvé la demande «lu syndicat coopératif 'Syndicat coopératif des produits laitiers de St-.Méthode »,dc cesser d'être régi par la Loi «les syndicats coopératifs de Québec, et de devenir une association régie par la Loi des associations coopératives, sous le nom dc « Association coopé rative de St-Méthode ».Québec, le 22 mai 1968.Le sous-secrétaire adjoint delà province, 24951-0 Lucien Darveau.Association coopérative dc St-Méthode (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given tliat the Provincial Secretary has approved the petition of the cooperative syndicate \"Syndicat coopératif des produits laitiers de St-Méthode\", to cease to be governed by the Quebec Cooperative Syndiimtes Act, ami to become an association governed by the Cooperative Associations Act, under the name of \"Association coopérative de St-Méthode\".Québec, May 22, 1968.Lucien Darveau, Associate Assistant Secretary 24951 of the Province. 3288 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° SA A»».rial ion coopérative des étudiants du collège de Maisonncuve (ACECM) {Loi des associations coopérai ires) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le changement de nom de l'association coopérative « Association coopérative des étudiants du collège Stc-Croix », en celui de « Association coopérative des étudiants du collège de Maisonncuve (ACEC.M) ».Québec, le 4 juin 1908.Le sous-ministrc des Institutions financières, compagnies et coopératives, 24952-0 Louis-Phi lippe BOUCHARD.Magasin Co-op du Bas St-Laurent (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation dc l'association coo]iéralive \"Magasin Co-op du Bas St-Laurent ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Rimouski, Québec, dans le district électoral de Rimouski.Québec, le 3 juin 19g8.Le sous-ministre des Institutions financières, compagnies et coopératives, 249g5-0 Louis-Philippe Bouchard.Association coopérative des étudiants du collège de Maisonncuve (ACECM) (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Minister o| Financial Institutions, Companies uiid Cooperatives approved the change of name of the cooperative association \"Association coopéralivc des étudiants du collège Ste-Croix\", into that of \"Association coopérative des étudiants du collège de Maisonncuve (ACECM)\".Québec, .lune 4.19g8.Lot is-Tiiii.ii'i'k Bouchard, Deputy Minister of Financial institutions, 24952 companies and co-operatives.Magasin Co-op du Bas Sl-Laureut (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the cooperative association \"Magasin Co-op du Has St-Laurent\".The head ollice of this cooperative association is situated at Rimouski, Québec, in the electoral district of Rimouski.Québec, June 3, 1968.Louis-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions.24965 Companies and Cooperatives.Caisse d'épargne et de crédit Caisse d'épargne et d'entraide économique de Richmond (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le secrétaire de la province a approuvé la formation de la caisse d'épargne et de crédit « Caisse d'épargne et d'entraide économique de Richmond ».Le territoire duns lequel lu caisse recrutera scs membres sera le comté de Richmond.Le siège social de celte caisse d'épargne el de crédit est situé à Asbestos.Québec, duns le di-lriet électoral de Richmond.Québec, le 22 mai 1968.Le sous-secrétaire de la prorince, 24954-0 Raymond Douville.Lettres patentes Etudes de Langues Atlas Itée Atlas Linguistic Studies Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première pari ie de la Loi des compagnies, il a plu au lieutenant-gouverneur ar le grellicr associé «lu Conseil législatif, comme suit: « Au nom de Sa Majesté, l'honorable lieutenant-gouverneur «le la Province sanctionne ces bills.24964-o Legislative Council Chamber Québec, 5th of June 1968.This day, at forty-five minutes past five o'clock in the afternoon, the Honourable the Lieutenant-Governor of the Province proceeded to the Legislative Council Chamber in the Legislative Building.The members of the Legislative Council being assembled, the Honourable the Lieutenant-Governor was pleased to command the atten-ilancc of the Legislative Assembly, and that House being present the Clerk of the Crown in Chancery read the titles of the bills to be sanctioned as follows: 30 An Act to amend the Finance Department Act.31 An Act to amend the Hydro-Québec Act.To these bills the Royal assent was pronouncetl by the Clerk Associate of the Legislative Council in the following words: \"In Her Majesty's name, the Honourable the Lieutenant-Governor of the Province assents to these bills.\" 24904-o Avis divers Miscellaneous Notices Majer Czartoryski Avis est donné que Majer Czartoryski, constructeur, domicilié à 4690 Vézina, ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Myer Charto; Icilit changement devra aussi servir à son épouse Henia.son fils Marvin et sa fille Susan, domiciliés ù 4690, Vézina, ville et district de Montréal.Montréal, le 24e jour de mai 1968.Le procureur du requérant, 24867-23-2 Laizeh Sirota.Majer Czartoryski Notice is hereby given that Majer Czartoryski, Builder, domiciled at 4690 Vézina, city and district of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in council for the adoption of a bill changing his name to Myer Charto; said change to apply to his wife Henia, son Marvin, and daughter Susan, domiciled at 4690 Vézina, city and district of Montréal.Montréal, the 24th day of May 1968.Laizer Sirota, 24857-23-2-0 A Uorney for Petitioner.Jocelyne Turner Vvis est par les présentes donné que Mlle Jocelyne Turner.pliysiothéru|>cutc, domiciliée à Ste-Tite, Co.Laviolctte.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer son nom «le Jocelyne Turner en celui dc Jocelyne Doiitigny, Les procureurs de Jocelyne Dontigny, RlVARD, RlVARD, 24!H7-23-2-o IIickson & Sirois.Jocelyne Turner Notice hereby given tliat Miss Jocelyne Turner, physiotherapeutist.domiciled at St.Tite Co.laviolctte, will make application to the Lieutenant-Governor in Counsel in order to cliange her name from Josclync Turner to Jocelyne Dontigny.RlVARD.RlVARD, IIickson & Sirois, 24917-23-2-o Attorneys of Jocelyne Dontigny.Andrew Buclian Cowe Avis est donné que Andrew Buchan Cowe instituteur, domicilié el résidant «le lu cité de DorvaL district de Montréal, province dc Québec, M résidant au numéro civique 357 avenue Court-¦nd, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son Born en celui de « Andrew Buclian Cowan».Montréal, ce 6ièmc jour dc juin, 1968.Le» procureurs du requérant, O'Brien Home Hall Nolan 24066-24-2-o Saunders O'Brien & Smith.Andrew Buclian Cowe Notice is given tliat Andrew Buclian Cowe teacher domiciled and residing in the City of Dorval, district of Montréal.Province of Québec and therein residing at 357 Courtland Avenue, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to tliat of \"Andrew Buclian Cowan\".Montréal, tins 6th day of June.1968.O'Brien Home Hall Nolan Saunders O'Brien & Smith, 24966-24-2-0 Attorneys for petitioner. 3290 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 2L Joanna Ainalia Haber Avis est ilonné que Roza Fried, ménagère, épouse de Rubin Fischer, épicier de la cité de St-Laurent, district de Montréal, s'adressera ai Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir que le nom de sa fille mineure, Joanna Amalia Haber, soit changé en celui de Joanna Amalia Fischer.Montréal, 28 mai 1968.Le notaire, 24948-24-2 Robert Glazer.Ronald Joseph Adelstcin Avis est donné que Ronald Joseph Adels-tein, résidant ù 2370, rue Gold, appartement 307, en la cité de St-Laurent, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil ufin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Ronald Joseph Mulinoff; ledit changement dc nom devra aussi servir à son é|)ouse, née Susan Schwartz à la même adresse, et ù son fils, né Bernard David Adelstcin, aussi à la même adresse.Montréal, 7 juin 1968.Les procureurs, Chait, Aronovitch, Salomon, 24997-24-2 Gelber, Reis & Bronstein.Joanna Amalia Haber Notice is hereby given that Roza Fried, house-wife, wife of Rubin Fischer, grocer of the City of St.Laurent, District of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of tin.Province of Quebec to have the name of her minor daughter.Joanna Amalia Haber, changed to Joanna Amalia Fischer.Montréal, May 28, 1968.Robert Glazku.24948-24-2-0 Notary.Ronald Joseph Adelstcin Notice is hereby given that Ronald Joseph Adelstcin, residing at 2370 Gold Street, Apart-ment 307, in the city of St.Laurent, district of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his naine to Ronald Joseph Malinoif; said change of name sliall also benefit his wife, liorn Susan Schwartz of the same address, and his son, born Bernard David Adelstcin, also of the same address.Montréal, June 7, 1968.Chait, Aronovitch, Salomon, Gelber, Reis & Bronstein, 24997-24-2-o Attorneys.Divers Compagnies Miscellaneous Companies Association de la Construction de Montréal Montreal Construction Association Avis est donné que le secrétaire dc la province a, le 15 mai 1908, approuvé le texte certifié français et anglais des amendements aux règlements généraux de « Association de la Construction de Montréal \u2014 Montreal Construction Association», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Dor ville.24972-0 14637-62 L.A.Brouillettc Itée Avis est donné que la compagnie « L.A.Brouillettc Itée » a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire, LÉON BlfOUILLETTE.24973-0 4477-67 Le Comité Canada The Canada Committee Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 22 mai 1968, approuvé les règlements numéros 1 ù 15 inclusivement de la corporation « Le Comité Canada \u2014¦ The Canada Committee », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.24974-0 993-68 l-e Comité Canada The Canada Committee Avis est donné que « Le Comité Canada \u2014 The ( 'anada Committee » a changé le nombre de ses administrateurs, de 12 à 15.Le secrétaire, C.F.Grover.24974 993-68 Association de la Construction de Moul réal Montreal Construction Association Notice is hereby given that the Provincial Secretary, on May 15.1908, approved the certified English and French texts of the amendments to general by-laws of \"Association dc la Construction de Montréal \u2014 Montreal Construction Association\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douvii.i.i.24972-0 Assistant Secretary of the I'rorinee.14637-02 L.A.Brouillettc Itée Notice is given that \"L.A.Brouillettc Itée\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Léon Brouillettc.Secretary.24973-0 4477-67 Le Comité Canada The Canada Committee Notice is hereby given that the Provincial Secretary has, on'May 22, 1908, approved the by-laws numbers 1 to 15 inclusively of the corporation \"Le Comité Canada \u2014The Canada Committee\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.24974 993-08 Le Comité Canada The Canada Committee Notice is given tliat \"Le Comité Canada \u2014 The Canada Committee\" has changed the number of its directors from 12 to 15.C.F.Grover, Secretary.24974-0 993-08 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15.1968, Vol.100, No.21 3291 Guilhart Mfg.Co.Ltd.Avis est donné que la compagnie « Guilhart Mfg.Co.Ltd.» a changé le nombre de ses administrateurs dc 4 à 3.Le secrétaire, JEANINE VlGNEAULT.2497.VO 15161-61 Hôtel Motel Fontainebleau (Montréal) inc.Avis est donné que la compagnie « Hotel Motel Fontainebleau (Montréal) inc.», a fixé le nombre de ses administrateurs a 5.Le secrétaire, Fernand Hardy.14976-0 2844-66 Mallard Maintenance Service Ltd.Avis est donné que « Mallard Maintenance Service Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 n 4.Le secrétaire, Roger Dubois.24977 1588-08 Matériaux Orford inc.Avis est donné que la compagnie « Matériaux Orford inc.».a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Suzanne B.Gagnon.249784 1098-63 Talarico Ltd.Avis est donné que la compagnie « Talarico Ltd, .a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire.Paul Mancuso.249794 12024-56 Napierville Automotive inc.Avis est donné que la compagnie « Napierville Automotive inc.», a changé le nombre dc ses administrateurs dc 4 à 3.La secrétaire, Thérèse L'Écuyer.24995-0 5091-65 Guilhart Mfg.Co.Ltd.Notice is given that \"Guilhart Mfg.Co.Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Jeanine Vigneault, Secretary.24975-0 15101-01 Hotel Motel Fontainebleau (Montreal) inc.Notice is hereby given that \"Hotel Motel Fontainebleau (Montréal) inc.\", lias fixed to 5, the number of its directors.Fernand Hardy, Secretary.24976 2844-60 Mallard Maintenance Service Ltd.Notice is given thar \"Mallard Maintenance Service Ltd.\", lias changed the number of its directors from 3 to 4.Roger Dubois, Secretary.24977-0 1588-08 Matériaux Orford inc.Notice is hereby given that \"Matériaux Orford inc.\", has changed the number of its directors, from 4 to 3.Suzanne B.Gagnon, Secretary.24978 1098-63 Talarico Ltd.Notice is hereby given thazt \"Talarico Ltd.\", has changed the number of its directors, from 5 to 3.Paul Mancuso, Secretary.24979 12024-68 Napierville Automotive inc.Notice is given that \"Napierville Automotive inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 3.Thérèse L'Écuyer, Secretary.24995-0 5091-65 Ministère de l'Éducation Department of Education Grande-Grève, diss.Demande est faite d'annexer le territoire actuellement sous la juridiction des syndics d'éeolei pour la municipalité de Grande-Grève, 'lai - le comté de Gaspé-Sud, à la municipalité \u2022eolairc de Cap-aux-Os, même comté.Québec, le 4 juin 1968.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.24943-23-2-0 640-04 Milan Val-Racine Demande est faite d'annexer le territoire actuel des municipalités scolaires de Milan et i al Racine, dans le comté dc Mégantic, à la municipalité scolaire de Lac-Mégantic, même comté.Québec, le 4 juin 1968.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.24944-23-2-0 165-04 Grande-Grcve, diss.Application is made to annex the territory presently under the jurisdiction of the School trustees for the municipality of Grande-Grève, in the county of Gaspé-South, to the School Municipality of Cap-aux-Os, same county.Québec, June 4, 1968.Jean-Guy Cardinal.Minuter of Education.24943-23-2 640-04 Milan Val-Racine Application is made to annex the present territory of the School Municipalities of Milan and Val-Racine, in the county of Mégantic, to the School Municipality of Lac-Mégantic, in the same county.Quéliec, June 4, 1968.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.24944-23-2 165-04 3292 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1968, 100' année, n° 24 Trois-Rivières-Cap dc la Madeleine (Prot.) Erratum Dand l'avis publié dans la Gazette officielle Je Québec du 18 mai 19G8, No 20, à la page 2909, concernant l'érection dc celte municipalité scholuire protestante, il faut ajouter dans le texte français après la quatrième ligne, lu ligne suivante qui a été omise: « de Trois-Rivières, sous le nom ».Québec, le 7 juin 1968.Le ministre de l'Éducation, 25003-o Jean-Guy Cardinal.Trois-Rhicrcs-Cap dc la Madeleine (Prot.) Erratum In tbc notice published in the Quebec Official Gazette on May 18, 1908, No.20, on page 2909, concerning the ereclion of this protestant school municipality, we have to add in the French text, after the fourth line, the following line that has been missed out: of Trois-Rivières, under the name\".Québec, June 7, 1968.Jean-Guy Cardinal, 25003 Minister of Education.Ministère des Finances Department of Finance Assurances Insurance Employers Mutual Fire Insurance Company Atis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « Employers Mutual Fire Insurance coniikiny » dont le siège social est situé à Wausau, état du Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, n'a pus fait d'affaires dans lu province dc Québec depuis le 23 février 1907; Attendu que « Employers Mutual Fire Insurance Company a produit au Service des assurances, une déclaration dûment sigué'c p.ir sou président et son secrétaire à l'effet qu'elle n'avait, au 17 mai 1908, aucune obligation dans la province dc Québec; En conséquence, avis est donné par les présentes que le permis et le certificat d'enregistrement de « Employers Mutual Pire Insurance Company» sont annulés à compter du 7 juin 1908.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des Institutions financières, compagnies et cooiiératives, le 7 juin 1968.l'our le ministre des Institutions financières, compagnies el coopératives dc la prorince, I.e surintendant des assurances, 25014-24-2-O ROOBR-À.Cam araire.United Investment Life Assurance Company La Compagnie d'Assurance-Vie United Investment .4 ri* d'émission de permis et de certificat d'eitriijislrement Avis est donné, par les présentes, que « l'nited Investment Life Assurance < 'ompany La ( 'oui-pagnie d'Assurance-Vie l'nited Invest ment », enregistrée sous le numéro 707, u obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1107, qui l'autorise à compter du 21 niai 1908.à effectuer dans la Province des Contracts d'assurance sur la Vie.Le siège social de la conqiagnic est situé à 85 ouest, rue Richmond, Toronto, province d'Ontario.La compagnie u nommé monsieur Peter-Noël Hiekey, 1210 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, son procureur duns lu Province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des Institutions financières, compagnies et coopératives, le 6 juin 1908.l'our le Ministre des Institutions financières, compagnies et coopérai ires de la Prorince, Le sun a ti n daitt des assurances, 24908-24-2-o Roueu-A.Camauaiki:.Employers Mutual Fire Insurance Company Notice of Cancellation of License and Certifiai) of Registration Whereas \"Employers Mutual Fire Insurance Company\" whose head ollice is situated in Wausau, Slate of Wisconsin, United States of American, haa not transacted business in the Province of Québec as from the 23rd of February 1907; Whereas \"Employer Mutual F'irc Insurance Company\" has filed with the Insurance Hi.mch a declaration duly signed by its President and it< secretary to the effect that it has as of May 17th.190S, no obligations in the Province of Québec; Consequently, notice is hereby given thai the license and certificate of registration of \"Employers Mutual Fire Insurance Company\" arc Cancelled as from the Tib of June 190S.Given at the office of the Insurance Hranch, Department of Financial Institutions, Coui|«-nies and Cooperatives, the 7th of June 196*.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the I'rorince, Rooeii-A.Camauaiiii:.25014-24-2-o Superintendent of Insurance.United Investment Life Assurance Company La Compagnie d'Assuraiicc-\\ ic United Investment Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"United Investment Life Assurance Company \u2014 La Compagnie d Assurance-Vie United Investment\", registered under Dumber 707.has obtained the license and cert ilicate of rcgisl ry number 1407.authorizing il.as from the 21st of May 1908, to undertake in the Province contracts of Life insurance.The head office of the company is situated at 85.Richmond Street West, Toronto, Province of Ontario.The company lias appointed Mr.Pclcr-Nnel Hiekcy.1210, Sherbrooke Street West, Montréal, its attorney ill the Province.Given at the office of the Insurance lira ah.Department of Financial Institutions, Compel ici and Cooperatives, the 6th of June 1908.For the Minister of Financial Institutions, ( 'ontjianies and L'otnieralires of the I'rorince.BOQBB-A.Camauaiki.24998-24-2-0 Superintendent of Insurance. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 15, 19GS, Vol.100, No.2L 3293 I uii'lon & Edinburgh General Insurance Company Limited Aria d'imiaaion de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que « London Edinburgh General Insurance Company Limited », enregistrée sous le numéro 708.a olitenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1409, qui l'autorise à compter du 27 mai 1008.à effectuer dans la Province des countrats d'assurance relatifs aux genres suivants: Accident; Automobile.I.e siège social de lu compagnie est situé ù 1, Seething Lune, Londres, Angleterre.|.a compagnie a nommé monsieur W.-X.Johnston.Suite 1880.Edifice Sun Life.Montréal, ¦on procureur dans la Province.Donné au bureau du Service îles assurances, ministère des Institutions financières, compagnies et coopératives, le 6 juin 1908.l'mir le ministre des Institutions financières, tompafnin et coopératives de la I'rorince.Le surintendant des assurances, 24999-24-2-0 Roosa-A, Camaraire.London & Edinburgh General Insurance Company Limited Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"London & Edinburgh General Insurance Company Limited\" registered under number 708.has obtained the license and certificate of registry number 1409, authorizing it, as from the 27th of May 1908, to undertake in the Province contracts of insurance of the following classes: Accident; Automobile.The head ollice of the company is situated at 1.Seething Lane.London, England.The company lias appointed Sir.W.X.Johnston.Suite 1880.Sun Life Building.Montréal, its attorney in the Province.Given at the ollice of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives, the 6th of June 1908.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the I'rorince, RooEB-A.Camakaikk.24999-24-2-0 Superintendent of Insurance.Ministère des\tDepartment of Affaires municipales\tMunicipal Affairs Municipulitt- du village de Vamaska Avis eat par les présentes donné par les soussignés (pie le lieutenant-gouverneur en conseil u adopté, en dute du 24 mai 1908, un arrêté en conseil ayant pour objet de clumger le nom de la municipalité du village de Saint-Michel, comté de Yama-kn, en celui de: « Municipalité du village de Vamaska '.( 'oiiforinémeiit à l'article 48du < 'ode municipal, iv changement de nom entre en vigueur à compter de In publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Village St-Michel.4 juin 1908.Le maire.Roland CÔTÉ.Le seerétain-trésorier, 24994m Prudent Pkoilx.Municipality of the Village of Yamaska Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted on May 24.1908, an Order in Council having for purpose to change the name of the municipality of the Village of St-Michel, county of Vanuiskn.to that of \"Municipality of the Village of Vamaska\", Pursuant to section 48 of the municipal Code, this change of name betimes effective from and after the publication of the present notice in Quéliec Official Gazette.St-Michel Village, June 4.1908.Hoi,ami CÔTÉ, Mayor.Prudent Pkoulx.24994 Secretary-Treasurer.Ministère de l'Industrie et du Commerce Department of Industry and Commerce loi sur les pêcheries Règlement dc pêche du Québec Avis de pêche aux coques Vu la diVision du ministre dc la Santé Nationale et du Bien-ÊI re Social ù l'effet que les coques des régions coquillères situées le long des côtes et des eaux: N-8.2 région s'étendent de la pointe est de la rivière Mistassini - Pointe à la Croix N-ll.l région s'étendant de la Pointe aux Anglais - Pointe Sproule ne sont plus toxiques à un point qui les rend dangereuses pour la consommation à l'état cru.A ces causes et conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement dépêche du Quéliec, Parles présentes, il plutt au Ministre d'ouvrir lesdites régions à la pêche et dc permettre à quiconque de pêcher, de prendre ou «l'avoir en sa possession «les coques provenant desdites régions.Quéliec, le 31 mai 1968.Le min istre de T Industrie et dut 'ont mené, 25004-o Jean-Paul Beau dry.Fisheries Act Québec Fishery Regulation Notice of Clam Fishing In view of the decision rendere«l by the Minister of National Health and Welfare to the effect that ehims in shellfish areas situated along the shores and waters: N-8.2 region extending from the eastern point of Mistassini Hiver-Pointe à la Croix N-ll.l region extending from Pointe aux Anglais - Pointe Sproule arc no longer toxic to a degree unsafe for use us a raw food.Therefore, pursuant to section 0.iiaragraph 1, of the Québec Fishery Regulation, the Minister is hereby pleased to open the said regions to fishing, and to allow whomsoever to fish, take or to have in his possession clams from the said areas.Quéliec, May 31, 1908.Jkax-Pail Bk.aiduy, 25004 Minister of Industry and Commerce. 3294 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 15 juin 1908, 100' année, n\" SA Demande à la Législature L'Oratoire Église Baptiste Française Avis est par les présentes donné que L'Oratoire Église Baptiste Française, une congrégation baptistc ayant sa place de services au 4863 rue Cartier, en la ville de Montréal, Province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour être incorpore sous le nom de « L'Oratoire Église Baptiste Française », conformément aux dispositions du chapitre 305, S.R.Q., 1964.24996-24-4-0 Application to Legislature L'Oratoire Église Baptiste Française Notice is hereby given that L'Oratoire Église Française, a Baptist Congregation having its place of worship at 4863 Cartier Street, in the city of Montreal, Province of Quebec, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for incor-poration under the name of \"L'Oratoire Kglisc Baptiste Française\", in conformity with the provisions of chapter 305, RSQ 1964.24990-21-1-0 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Canton de Mulgravc Cadastre officiel du canton de Mulgravc, municipalité des Cantons Unis de Mulgrave et Derry, division d'enregistrement de Papineau.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 43-40 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 avril 1968.Le sous-mini sire, 25005-o Fernand Boutin.Cité dc Montréal, Quartier Si-Antoine Cadastre officiel de la cité de Montréal, quartier St-Antoine, municipalité de la ville dc Montréal, division d'enregistrement dc Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 991-1 à 991-5, 991, 992, 993, 996 à 1000, 1000A, 1001-12, 1001-13 et une partie des lots 994, 995.1001, 1001-1 à 1001-5.1001-9, 1001-10, 1001-11 et 1001-14 sont annulés et les lots 1951 et 1952 sont ajoutés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 3 juin 1968.Le sous-ministre, 25005-o Fernand Boutin.Municipalité de la paroisse de Montréal Cadastral officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, inunici|«ilitc de la ville de Montréal, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 1900-1, 1901, 1901-1 à 1901-3, 1902, 1902-1 à 1902-3, 1903, 1903-1 il 1903-3, 1904, 1904-1, 1904-2, 1905-1, 1905, 1905-2, 1921, 1921-50 à 1921-87 et une partie du lot 1900 sont annulés et les lots 4829 et 4830 sont ajoutés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 28 mai 1968.Le sous-ministre, 25005-o Fernand Boutin.Paroisse dc Charlesbourg Cadastre ofliciel de la paroisse de Cliarlesbourg, municipalité de la ville de Notre-Dame des Laurentides, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 465-4 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 mai 1968.Le sous-ministre, 25005-o Fernand Boutin.Township of Mulgrave Official cadastre of township of Mulgravc, municipality of United Townships of Mulgrave and Derry, registration division of Papineau.Notice is hereby given that the remaining part of lot 43-40 is cancelled in virtue of Article 2174.of the Civil Code.Quebec, April 24, 1968.Fernand Boutin, 25005-o Deputy Minister.City of Montreal, St-Antoine Ward Official cadastre of the city of Montreal, St.Antoine Ward, municipality of the town of Montreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 991-1 to 991-5, 991, 992, 993, 996 to 1000, 1000A.1001-12.1001-13 and one part of lots 994, 995.1001, 1001-1 to 1001-5, 1001-9, 1001-10.1001-11 and 1001-14 are cancelled and lots 1051 and 19,i2 are added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, June, the 3, 1968.Fernand Boutin, 25005-o Deputy Minister.Municipality of the parish of Montréal Official cadastre of the municipality of the parish of Montréal, municipality of the town of Montréal, registration division of Montréal.Notice is hereby given that lots 1900-1, 1901.1901-1 to 1901-3.1902, 1902-1 to 1902-3, 1903, 1903-1 to 1903-3, 1904, 1904-1, 1904-2, 1905-1, 1905, 1905-2, 1921, 1921-50 to 1921-87 and one part of lot 1900 are cancelled and lots 4829 and 4830 are added in virtue of article 2174A of the Civil Code.Québec, May 28, 1968.Fernand Boutin, 25005-o Deputy Minister.Parish of Charlesbourg Official cadastre of the jnrish of Charlcslxiurg, municipality of the town of Notre-Dame des Laurentides, registration division of Quéliec.Notice is hereby given that the lot 465-4 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, May 10, 1968.Fernand Boutin, 25005-o Deputy Minister. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June IB, 1968, Vol.100, No.21 3295 Paroisse de St-Colomb de Sillery Cadastre officiel de la paroisse dc St-Colomb de Sillery, municipalité de la cité de Sillery, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 105-607-1, 105-608-1, 105-609-1, 105-610-1, 105-611-1, 105-612-1 et 105-613-1 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 juin 1968./,
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.