Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 22 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1968-06-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle à Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE QuôImt, samedi 22 juin 1968 Règlements 1° Adresser toute correspondance à: l'Imprimeur de la reine, Hôtel du Gouvernement, Québec 2 Fournir le texte de l'annoTcc dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en e>t faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3J Indiquer le nombre d'insertions.1' Payer comptant et avant publication le coill des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droit» de l'Imprimeur de la reine qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.¦> I, abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle de Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire a midi, le mardi.Les avis, documents on annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Imprimeur de la reine a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8\" Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9' Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés \u2022l'en aviser l'Imprimeur de la reine avant la ¦Monde insertion et ce, afin d'éviter de part et u'uulrc des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, June 22, 1968 Rules 1.Address all communications to the Queen's Printer, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements arc payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to the Queen's Printer, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.G.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach the Queen's Printer not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, the Queen's Printer reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Queen's Printer before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Publiée par le Gouvernement de la Province / Published bt the Provincial Government L'Imprimeur de ta reine, roch lefebvre, Queen i Printer \u2014 Québec 3314 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, «\u2022 25 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $3 des 100 mots.Exemplaire séparé: 50 cents chacun.Feuilles volantes: $2 la douzaine.Abonnement: $10 par année il compter de janvier.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre coni|)o-sition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Imprimeur de la reine, Rocu Lbfebvrb.Hotel du Gouvernement, Québec, 13 mars 1968 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $3 per 100 words.Single copies: 50 cents each.Slips: $2 per dozen.Subscriptions: $10 per year from January.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertion.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by Queen's Printer personnel.Notices published only once arc followed by our invoice number.Rocu Lefkbvrk, Queen's Printer.Parliament lluildings, Québec, March 13, 1908 24070 \u2014 1 l-.n-o Le Ministère des Postes, à Ottawa, a autorisé l'affranchissement en numéraire et l'envoi comme objet de deuxième elas.se do la présente publication.Authorized as .second class mail by the Post Office Department.Ottawa, and for payment of postage in cash.Lettres patentes Abbey Tavern Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la I-oi des com|iuguies, le lieutenuut-gouverneur de lu province u accordé deslettres patentes, en date du 20e jour d'avril 1908, constituant en corporation: Janice Johnston, 6925, avenue Outremont, Rosa L.Nelson, 4300, Bourret, et Laura Cobb, 2400, Benny Crescent, toutes trois secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: Exercer le commerce de traiteurs et de restaurateurs, sous le nom de \u2022 Abbey Tavern Ltd.», avec un capital total de S 10.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrflaire de la prorince, Raymond Dou ville.25015 1711-68 Acadian Epicure Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes, en date du 8c jour de mai 1968, constituant en corporation: Roger A.Bouvet, 736, Arthur-Sauvé, Laval, Claude Bouvet, 1000, Pratt, Outremont, W.(î.Bruylcy, Saint-André-sur-Mer, province du Nouvcau-Brunswick, Jeun Loevenbruek, 648, Grosvenor, Cilles Amiot, 487S, Grosvenor, tous deux de Westmount, et Claude Bourguignon, 18.Beach, Byram.Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, tous six administrateurs, pour les objets suivants: Letters Patent Abbey Tavern Ltd.Notice is given that under Part I of Hie Coni|>anies Act.letters patent, bearing dale I lie 29th day of April, 1968, liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Janice Johnston, 6925 Outrcinonl Avenue, Rosa L.Nelson.4300 Bourret.and Laura Cobb.2400 Benny Crescent, all three secretaries spinsters, of Montreal, for the following pur|ioscs: To carry on business as caterers and restaurateurs, under the name of \"Abbey Tavern Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.k.Assistant Secretary of the Province.25015-O 1711-68 Acadian Epicure Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, l>earing date the 8th day of May.1968, have licen tamed by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger A.Bouvet, 736 Arthur-Sauvé, Uval, Claude Bouvet 1000 Pratt, Outremont, W.G.Braylcy, Saint-André-sur-Mi i Province of New Brunswick, Jean Loevenbruek.648 Grosvenor, Gilles Amiot, 4878 Grosvenor.both of Westmount, and Claude Bourguignon.18 Beach, Byram, Connecticut, United States of America, all six administrators, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1908, Vol.100, No.25 3315 Manufacturer et faire le commerce de produits alimentaires de toutes sortes, sous le nom de iAcadian Epicure Inc.», avec un capital divisé en 10.(100 actions ordinaires sans valeur nominale et en -10.000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25010-0 2162-68 Adanox ltée Avis est donné qu'en vertu de la première initie île la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: René (Joycttc, administrateur, 84, rue Sylvestre, Réjanc Beauchcmin, secrétaire, épouse contraetuellement séparée de biens de François Gcrvais, 104.rue Vallières.tous deux de Lac Lemoine, et Andrée Philbcrt, secretaire, fille majeure, 1020, rue Bérard, Val d'Or.pour les objets suivants: l'aire affaires comme distributeurs en gros de tonics marchandises électriques, couvre-planchers, plomberie, quincaillerie, sport et meubles de Ionics sortes, sous le nom île « Adanox Itée '.avec un capital total de 8200,000, divisé en 10.000 allions ordinaires de S10 chacune et en 10.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la com|>ugnic est à Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Le .sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1848-68 L'Agence Fleur de Lys inc.Avis es! donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres pstentes, en date du 3e jour de mai 1968.constituant en corporation: Jacques-A.Gaudette.428, Maric-Rollet, Pierre-J.Gaudette, 5.Village Suisse, lous deux comptables agréés, et Claude Thihodcau, comptable, 431, Boyer, tous trois de Saint-Jean, pour les objets suivants: l'aire affaires comme éditeurs, graveurs, imprimeurs, relieurs et faire le commerce de timbres-primes, sous le nom de « L'Agence Fleur de Lys me.avec un capital total de $40,000, divisé en 'i.llOtl actions ordinaires de SI chacune et en 350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Jean, district judiciaire d'Iberville.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2501,1-0 2077-68 Ben Ash Delicatessen (Côte des Neiges) Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de mai 1968, constituant en corporation: Louis Orenstein, avocat et conseil en Loi de la reine, 5654, avenue MacDonald, Hampstcad, Jason Ruby, avocat, 47, Place du Bois, Dollard-des-Ormeaux, et Glacia Miller, secrétaire, célibataire, 3201, avenue Forest Hill, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme fournisseurs de nourriture «le toute forme, nature et description, y compris les produits de cliarcuterie (delicatessen), sous le nom de t Ben Ash Delicatessen (Côte des Neiges) To manufacture and deal in all kinds of food products, under the name of \"Acadian Epicure Inc.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares of no nominal value and 40,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2162-68 Adanox ltée Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: René Goyette, administrator, 84 Sylvestre St., Réjane Beauchemin, secretary, wife contractually separate as to property of François Gervais, 104 Vallières St., both of Lac Lemoine.and Andrée Philbert, secretary, spinster of the full age of majority, 1020 Bérard St., Val d'Or, for the following purposes: To carry on business as wholesale distributors of all electrical merchandise, floor coverings, plumbing equipment, liardware, sports equipment and furniture of all kinds, under the name of \"Adanox ltée\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 10,000 common shares of $10 each and 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1848-68 L'Agence Fleur de Lys inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorfxirating: Jacques-A.Gaudette, 428 Marie-Rollet, Pierrc-J.Gaudette, 5 Village Suisse, l>oth chartered accountants, and Claude Thibo-deau, accountant, 431 Boyer, all three of Saint John's, for the following purposes: To carry on business as editors, engravers, printers, bookbinders and to deal in the premium stamp business, under the name of \"L'Agence Fleur de Lys inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of $1 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint Jolin's, judicial district of Iberville.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2077-68 Ben Ash Delicatessen (Côte des Neiges) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Orenstein, advocate and Queen's Counsel, 5654 MacDonald Avenue, Hampstead, Jason Ruby, advocate, 47 Place du Bois, Dollard-des-Ormeaux, and Glacia Miller, secretary, spinster, 3201 Forest Hill Avenue, Montreal, for the following purposes: To carry on business as dispensers of food of all forms, nature and description, including delicatessen products, under the name of \"Ben Ash Delicatessen (Côte des Neiges) Ltd.\", with 3316 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1908, 100' année, n° 25 Lui.», avec un capital total de $-10,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvilli:.25015 2185-68 Aspec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour de mai 1908, constituant en corporation: Pierre-Luc Blain, 10582, Clark, Montréal, Marc Leblanc, 107, Ashton, Saint-Laurent, tous deux avocats, et Jacqueline Mover, secrétaire, lillc majeure, S390, Maric-Victorin, Brassard, |>our les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie (l'immeuble et de construction, sous le nom de < Aspec inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale de SUM) chacune et en 900 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 175, rue Yimy, .Saiiit-Miuno-dc-Moiitarville, district judiciaire de Montréal.Le mus-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2059-68 Associated Photographers of Place Bona venture Inc.Photographes associés de Place Bona venture inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mai 1968, constituant en cor|)oration: Hugh Frankcl, Si oil Frankel, tous deux de 52-13, (ilolicrt, Montréal, et Roland Sirois, fils, 3905, rue F.thcl, Verdun, tous trois photographes, |k>ur les objets suivant»: Exploiter un commerce de photographes et reproducteurs de gravures et agir à titre d'artistes et artistes commerciaux, sous le nom de « Associated Photographers of Place Bonaventure Inc.\u2014 Photographes associés de Place Bonaventure inc., avec un capital total de $10,000, divisé en 10.000 actions ordinaires de SI chacune et 30.000 actions privilégiées de $1 cliaeunc.Le siège social de lu compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015 2159-68 Astro Chemicals Inc.Les Produits chimiques Astro inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ixii des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour d'avril 1968, constituant en corporation: George Pirat, vendeur, Ingelmrg Mocsslcr, teneur de livres, tous deux de 4650, Samson, Laval, et Jcan-Jacqucs Hamel, avocat, 621, Thébergc, Terrebonne, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de produits chimiques de toutes sortes, sous le nom de « Astro Chemicals Inc.\u2014 Les Produits chimiques Astro inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 cliaeunc.a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head oflicc of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the 1'roeiure.25015-o 2185-68 Aspec inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Gill day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre-Luc Blain, 105S2 (lark, Montréal, Marc Leblanc, 107 Ashton, Saint-Laurent, both advocates, and Jacqueline Mover, secretary, spinster of the full age of majority, 8390 Marie-Victorin, Brossard, for the following purposes: To carry on business as a real estate and con.struetion com|wiiy, under the name of \"A»|mt inc.\", with a total capital slock of $100.000.divided into 100 common shares of a nominal value of $100 each mid 900 preferred class \"A\" shares of a nominal value of $100 each.The head ollicc of the company is at 175 Yiiny Street, Saint-Briino-de-Monûirville, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2089-68 Associated Photographers of Place Bonaventure Inc.Photographes associes de Place Bonaventure inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters |>atcnt, bearing dale llie 10th day of May.1968.luive been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, moor-(mratiug: Hugh Frankcl, Scott Frankcl, IhiIIi of 5243 Glnhcrt.Montreal, and Roland Sirois Jr.3995 Ethel Street.Verdun, all three photographers, for the following purposes: To carry on business as photographers and reproducers of pictures and to act as artists and commercial artists, under the name of \"Associated Photographers of Place Bonaventure Inc.\u2014 Photographes associés de Place Bonaventure inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10.000 common shares of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head office of the eomiMiny is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.25015-o 2159-08 Astro Chemicals Inc.Les Produits chimiques Astro inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters |>atcnt, bearing date the 26th day of April, 1968, liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: George Pirat, salesman, Ingcliorg Moesslcr, Iwokkeeper, both of 4650 Samson, I .a val.ami Jean-Jacques liai nr I.advocate.621 Thébcrge, Terrebonne, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of chemical products, under the name of \"Astro Chemicals Inc.\u2014 Les Produits chimiques Asl ro inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred sliarcs of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22.19GS, Vol.100, No.25 3317 Le siège social rie la compagnie est 4650, boulevard Samson, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1874-68 B.C.F.Erectors Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres intentes, en date du 8e jour de mai 1968, constituant en corporation: Paul Bujold, 11520, Lacor-daire, Roger Fauteux, 11047, (iingras, tous deux de Montréal-Nord, et Edmond Chauvin, 3042, Fletcher, Montréal, tous trois contremaîtres, pour les objets suivants: l'aire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « 11.C.F.Erectors Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires rje 810 chacune.I.c siège social de la compagnie est 11047, rue (iingras, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1739-68 Robert et Gérard Benoit inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date (lu 7c jour de mai 1968, constituant en corporation: Gérard Benoit, 219, Duquette, Robert Benoit, 137, Marquette, tous deux entrepreneurs, et Alvin Mac Aulay, comptable.33, Lallemant, tous trois de Cliàtcauguay, pour les objets suivants: l'aire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Robert et Gérard Benoit inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,500 actions ordinaires de S10 chacune et en 500 actions privilégiées de $10 chacune.I.c siège social de la compagnie est 219, rue Duquette, ^ Chftteauguay, district judiciaire de Heauharnois.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.250 I5-o 2078-68 Bio-Tccbniç Beauty Equipment Inc.Itio-Tccbnic Equipement de beauté inc.Avis est domié qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de mai 1968, constituant en corporation: Irving Shapiro, avocat, 4957, Isabella, Ilessa Wcllen, secrétaire, fille majeure, 4946, Kent, tous deux de Montréal, et Stanley L.Cytrynbaum, avocat, 95, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de cosmétiques ft produits de beauté, sous le nom de « Bio-I c.Imic Beauty Equipment Inc.\u2014 Bio-Tecimic Equipment de beauté inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordi-[uurcs de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.26015 1998-68 The head office of the company is al 4650 Samson Blvd., Laval, judicialdistrictof Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1874-68 B.C.F.Erectors Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 8th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Bujold, 11520 Lacordaire, Roger Fauteux, 11047 Gingras, both of Montreal-North, and Edmond Chauvin, 3042 Fletcher, Montreal, all three foremen, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, under the name of \"11.C.F.Erectors Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 11047 Gingras Street, Montreal-North, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1739-68 Robert et Gérard Benoit inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Benoit, 219 Duquette, Robert Benoit, 137 Marquette, both contractors, and Alvin Mac Aulay, accountant, 33 Lallemant, all three of Chftteauguay, for the following purposes: To carry on business as constructors and general building contractors and to deal in all kinds of material, under the name of \"Robert et Gérard Benoit inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,500 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 219 Duquette Street, Chftteauguay, judicial district of Bcauharnois.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2078-68 Bio-Technic Beauty Equipment Inc.Bio-Techuic Équipement de beauté inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Irving Shapiro, advocate, 4957 Isabella, Hcssa Wellen, secretary, spinster of the full age of majority, 4946 Kent, both of Montreal, and Stanley L.Cytrynbaum, advocate, 95 Roxton Crescent, Montreal West, for the following purposes: To manufacture and deal in cosmetics and beauty products, under the name of \"Bio-Technic Beauty Equipment Inc.\u2014 Bio-Technic Équipement de beauté inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 1998-68 3318 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.22 juin IOCS.100' année, u' 2'» Boulangerie Jean-Raymond inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de In Loi des coniiwgnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 1 (5e jour «le mai 1068, constituant en cor|x>ration: Raymond Caston-guay, soudeur, Clémence Lévesque, ménagère, épouse séparée de biens «ludil Raymond Cas-tonguay, Jean-Marie Pelletier, soudeur, et Jocclyne Roy, ménagère.é]k>use commune en laens dudit Jean-Marie Pelletier, tous quatre de Cap-Chat, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du pain, de gâteaux, pâtisseries et autres articles d'alimentation, sous le nom de < Boulangerie Jean-Raymond inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Cap-Chat, district judiciaire de Gaspé.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1955-68 Butler Auto Fabrics (1968) Ltd.Avis est ilonné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieulcnanl-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 1908, constituant en corporation: Frank M.(iodine, avocat et conseiller en I/>i de la reine, 4800, chemin de la Côte des Neiges.Harry Blank, avocat, 4625, avenue Miller, et Rhoda Cohen, secrétaire, fille majeure, 6427, avenue MacDonald.tous trois de Montréal, pour les objets suivants: La fabrication et le commerce de tissus et d'étoffes pour les automobiles et autres produits connexes, sous le nom de « Butler Auto Fabrics (1968) Ltd.», avec un capital total de $40.000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 cliaeunc.Le siège social de la coni|>agnie est 215 ouest, rue Jean-Talon, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douville.25015 2058-68 C.B.Maintenance Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres (latentes, en date du 2e jour de mai 1968, constituant en cor|ioration: Rémi Chevrier, entrepreneur, Jcannine Mallette, ménagère, épouse conlractuellemcnt séparée de biens dudit Rémi Chevrier, tous deux de 90, boulevard Du Moulin, et Jean-Paul Brûlé, opérateur, 6A.Lcroyer, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « C.B.Maintenance Inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.25015-o 2080-68 Candare Radio Taxi Inc.Boulangerie Jean-Raymond inc.Notice is given that under Part I of ||ie Companies Act, letters patent, bearing date t|ie 16th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, iiicor-pornting: Raymond Castonguay, welder.Clé.menée Lévesque, housewife, wife separate as to properly of said Raymond Castonguay, Jean-Marie Pelletier, welder, anil Jocclyne Roy, housewife, wife common as to property of said Jean-Marie Pelletier, all four of Gap-Chat, for the following purposes: To manufacture and deal in bread, calm, pastries and other food products, under the name of \"Boulangerie Jean-Raymond inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of $10 each.The head office of the company is al Cap.Chat, judicial district of Gaspé.Raymond Douville, Assistant Secretary of the I'rorinre.25015 1955-68 Butler Auto Fabrics (1968) Ltd.Notice is given that under Part I ot the Companies Act, letters |>atcnt, bearing late the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, iueorimraling: Frank M.(iodine, advocate anil Qpeen's Counsel, 4800 Côte des Neiges Rond.Harry Blank, advocate, 4625 Miller Avenue, ami It lu» la Cohen, secretary, spinster of the full age of majority, 6427 MacDonuhl Avenue, all three of Montreal, for the following purpo-cs: To manufacture and deal in or with auto and other kinds of fabrics and fabric products, under the name of \"Butler Auto Fabrics (I'.KiS) Ltd.\".with a total capita] stock of $40.000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 215 Jean-Talon Street West, Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Sccretan/ of the Province.25015-o 2038-68 C.B.Maintenance Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent* bearing date I he 2nd day of May, 1968, have been issued by I he Lieutenant-Governor of the Province, incorpo-rating: Rémi Chevrier, contractor, Jcannine Mallette, housewife, wife contractually sépara le as to property of the said Rémi Chevrier, both of 90 Du Moulin Blvd., and Jean-Paul Brûlé, operator, 6A Leroyer, all three of Laval, for the following pur|x)ses: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in nil kinds of materials, under the name of \"C.B.Maintenance Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20.000 common sliares of a nominal value of $1 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2080-08 Candare Radio Taxi Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the St h day of May, 1968, have been issued by the Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1008, Vol.100, No.26 3319 patentes, en date é.10803, rue Berri.tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, véhicules automobiles, pneus, machines.accessoires et parties, outils, instruments et appareils, produits et articles relatifs à l'industrie et au commerce de l'automobile en général, sous le nom de «('entre du Pneu Jolicttc ltée », avec un capital total de $90.000, divisé en 2.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 700 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1238, rue De Lanaudièrc, Joliette, district judiciaire de Joliette.Theodolinda De Pippo, housewife, wife common as to property of said Mario Delia Serra, both of 6092 Robert Boulevard, Antonio Iatauro, restaurant keeper, and Santa Cannata, housewife, wife common as to property of said Antonio Iatauro, the latter two of 6084 Louvain, all four of Saint-Léonard, for the following purposes: To carry on business as an investment com.pany, under the name of \"Caserta Investments Ltd.\u2014 Placements Caserta ltée\", with a total capital slock of $10,000, divided into 1,000 com.mon shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.25015 2053-68 Centre d'Activités sociales de St-Joachim inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date I lie 0th day of May.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Marcel Hoiissin, inspector.105 Philippe St reel, Rolicrt-E.Mctclafe.salesman.185 SI-i,oiii.Street, and Jean-Marc .louhcrt, verifier, 98 Giroux Street, all three of ChaU'auguny-t cidre, for the following purposes: To o|HTute a center for different social activities, iMirochial.cultural or sporting, under the name «>f \"Centre d'Activités sociales de St-Joachim inc.\".The amount to which is limited the immovable Property which the corporation mav acquire and possess,* is $100.000.The head oflice of the corjsiration is at ChA-teguay-Centre, judiciul district of Beauharnois.Raymond Doi ville.Assistant Secretary of the Product.25015 2006-68 Centre du Pneu Joliette ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing dale the 13th day of May.1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Zotique Aubé, annuitant.1052 Henri-Bourassa East.Vianney Paquette, accountant, 10661 Georges-Baril Street, and Irma Lessard, housewife, wife separate as to property of GuS Aubé.10803 Berri Street, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage-kcc|XTS and lo deal in automobiles, motor vehicles, tires, machines, accessories and parts, tools, instruments and appliances, products and articles relative to the automobile industry in general, under the name «>f \"Centre du Pneu Joliette ltée», with a total capital stock of 180,000, divided into 2.000 common shares of a nominal value of $10 each and into 700 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 1238 De Lanaudièrc Street, Joliette, judicial district of Jolicttc.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province, 25015 2141-08 Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2141-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3321 Ix-s Cercles de Fermières de la Province de Québec Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le lu Loi des compagnies, le lieutenant-piuverncur de lu province a accordé des lettres patentes, en «late «lu 6c jour de mai 1968, constituant en cor|k>rution sans capital-actions: Yvonne Xudcau, ménagère, veuve non remariée d'Ailélard .lolin, Soint-Raplmlil-de-Hcllecliasse, l-'iv léliiic Thibault, ménagère, épouse commune eu biens de Joseph Caron.7.Lefehvre.Coati-nuik.Gaby Hurtuhise, ménagère, épouse com-iin: ecu biens de Charles Hernard.4\").Ire avenue, Place «les Erables, Laval et Éva Laflammc.ménagère.ép«)use séparée de biens de Hennas Droilin, Sainte-Agathc-de-Lotbinière, pour les objets suivants: Promouvoir le déveloj)pcment moral, culturel cl sucial de la femme, la stabilité des foyers par ku influence dans la famille et dans la société, Bus le nom de « Les Cercles de Fermières de la Province de Québec ».I.c montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 81.000.000.Le siège social de la corporal ion est ù Québec, district judiciaire de Quél>cc.Le son* tterétain de la prorince, Raymond Douville.250184 2060-68 Château Lac Reauport (1968) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnaiit-eouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Henri Fortin.5120.3e avenue.Charlcsbourg, Jean-Marc Rouchard, 'M.Miramont.XeufehAtcI, et Claude Hoyer, 2785, Poitiers, Suinte-Foy, tous trois notaires, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, motels, auberges et maisons de touristes, sous le nom de « Clultcnu Lac Keauport .(1968) inc.», avec un capital total 'li s 10,000, divisé en 1.000 actions ordinaires «le 81\" chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Ii- siège social «le la compagnie est à Saint-Dunstan-du-Lac-Bcau|)ort, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.25015m 1969-68 Choeur Les Rhapsodes Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouvemeur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Andrée Gilbert, secrétaire, fille majeure, 2550, Montbray, Robert Rousseau.920, Myrand, tous deux de Siiiile-Foy, et Pierre Frechette, 642, 20e rue Cliarny, ces deux «lerniers étudiants, pour les objets suivants: Etablir et maintenir une chorale, sous le nom de < Choeur Les Rhapsodes ».I.c montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la (-orporation, est de $50,000.I.c siège social de la corporation est il Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2102-68 Les Cercles de Fermières de la Province de Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing ilate the 6th day of May, 1968, liave liecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Yvonne Nadeau.housewife, unremarried widow of Adélard .lolin.Suint-Raphaël-dc-Rellechasse, Frédélinc Thibault, housewife, wife common as to property of Joseph Caron.7 Lefebvre.Coati-cook.Gaby Hurtuhise.housewife, wife common as to property of Chanel Bernard, 45, 1st Ave., Place des Érables, Laval, and Éva Laflamme, housewife, wife separate as to properly of Hernias Drouin, Sainte-Agathe-de-Lotbiiiièrc, for the following purposes: To promote the moral, cultural and social development of women, the stability of homes by their influence on the family and on society, under the name of \"Les Cercles de Fermières de la Province de Québec\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $1.000,000.The head ollicc of the corporation is at Québec, judicial district of Quéliec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 2060-68 Château Lac Reauport (1968) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor-porating: Henri Fortin, 5120, 3rd Ave.Charles-bourg, Jean-Marc Rouchard, 31 Miramont, NeufchAtel.and Claude Hoyer.2785 Poitiers, St.Foy, all three notaries, for the following purposes: To operate hotels, motels, inns and tourist homes, under the name of \"Chateau Lac Beau-port (1908) inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1.000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head oflice of I he company is at Saint-Dunslun-du-Lac-Bcaiiport, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1969-68 Choeur Les Rhapsodes Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Andrée Gilbert, secretary, spinster of the full age of majority, 2550 Montbray, Robert Rousseau, 920 Myrand, both of St.Foy.and Pierre Frechette, 642, 20th St., Cliarny, the latter two students, for the following purposes: To establish and support a choir, under the name of \"Choeur Les Rhapsodes\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Québec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2102-68 3322 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.22 juin 19ns, 100' année.n° 25 Ciné-Parc des I.aurcntidcs inc.I anient ide Outdoor Cinema Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour d'août 1067, constituant en corporation: Fcrnand-M.Rousseau, agent d'affaires.Denise Dcslauricrs, ménagère, épouse séparée de biens dudit Fernand-M.Rousseau, tous deux de 12134, rue Taylor.Maurice Danis, gérant, et Thérèse Martial, ménagère, épouse séparée de biens dudit Maurice Danis.ces deux derniers de 1435, lxwlevard Pic IX, tous quatre de Montréal, |X)ur les objets suivants: Exploiter une agence de théAtrc, sous le nom de « Ciné-Parc des Laurcntidesinc.\u2014 Lnurcntidc Outdoor Cinema Inc.», avec un capital total de 840.000.divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-sec réta ire de la province, Raymond Douville.25015-o 3220-67 Club de Croquet Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de In troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 1068, constituant en corporation sans capital-actions: René Lafond, fonctionnaire, Louise Uédard, ménagère, épouse dudit René Lafond, tous deux de 4853, rue des Pervenches, Orsainville, Fcr-nand Picard, 583, Stc-Thérèse, Lucien Bédard, 192, St-Ambroise, Paul-Emile Renaud.222, lie rue, tous trois commis.Lauréat Trépanicr, employé civique, 220, lie rue, Philippe lleaiiinont, boucher, 169, rue du Roy, Victor Hédard, fonctionnaire, 358, rue St-Agnès, tous six de Québec, et Gaétan Rédard, technicien, 87, St-Charles, Neuf eh A tel, pour les objets suivants: Former et exploiter un club de croquet, sous le nom «le « Club de Croquet Québec inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de la corporation est au Parc Dollard, avenue Stc-Thérèse, Québec, district judiciaire de Québec.Iai tout-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2150-6S Le Club Nautique Mari un- Maria inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentee, en date du 6e jour de mai 1968, constituant, en coriioration sans capital-actions: Vvon Bernard, professeur, Gilles Fortier, conseiller financier, Raoul Poirier, avocat, Donat LcBlanc, et Adrien Bernard, ces deux derniers gérants, tous cinq de Maria, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport du yachting, de la navigation de plaisance, du ski nautique, de la natation et autres sports connexes, sous le nom de « Le Club Nautique Marina-Maria inc.».Le montant auquel est limitée lu valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Ciné-Parc des Lnurentides inc.Lnurcntidc Outdoor Cinema Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of August, 1967.have licen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor-pointing: Fernand-M.Rousseau, business ., .,,| Denise Dcslauricrs, housewife, wife scjNiralc as to property of the said Fernand-M.KOUSScau, both of 12134 Taylor St., Maurice Danis, maai.ger, and Thérèse Martial, housewife, wife sept-rate as to property of the said Maurice Daub, the two latter of 1438 Pie IX Blvd., all four of Montreal, for the following purposes: To o|X'rate a theatrical agency, under the name of \"Ciné-Parc des I.aurcntidcs inc.\u2014 Laurent iilp Outdoor Cinema Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Ptorinee.20018 822047 Club dc Croquet Queliee inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to mcorpo-rate a coqioration without share capital: René Lafond, civil servant.Louise Bédard, housewife, wife of said Rene Lafond, both of 4853 des Pervenches Street, Orsainville, Fernand Picard, 5S3 Stc-Thérèse.Lucien Bédard, 192 St-Ambroise, Paul-Emile Renaud, 222, lllh Street, all three clerks.Lauréat Trépanicr, civic employee, 220, lltb Street.Pihlippe Beaumont, butcher.Kill du Roy Street, Victor Bédard, civil servant.388 St-Agnès Street, all six of Québec, and Gaétan Bédard, technician, 87 St-Charlcs, Ncufchâtel, for the following purposes: To form and operate a croquet club, under the name of \"Club de Croquet Québec inc.\".The amount to which is limited the value of I be immovable property which the cor|wration may acquire and possess, is $100,000.The head ollice of the corporation is at Pare Dollard, Ste-Thérèsc Avenue, Québec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2150-6S Le Club Nautique Marina-Maria inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date Ihe 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorpo-rate a corporation without share capital: ^ von Uernard, professor, Gilles Fortin, financial consultant, Raoul Poirier, advocate, Donat LcBlauc, and Adrien Bernard, the two latter managers, all five of Maria, for the following purposi - To fonn and operate a sports club, and particularly to promote the sport of yachting, pleasure sailing, water skiing, swimming and other related sport.% under the name of \"Le Club Nautique Marina-Maria inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $500,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3323 Le siège social de la corporation est à Maria, district judiciaire de Bonaventure.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2061-68 Club social et sportif Le Chevalier Avi» est donné qu'en vertu de la troisième ptrue de lu Loi des compagnies, le lieutciiaut-puivcrneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mai 1908, constituant en cnrixirutiou sans capital-actions: Magella Dolbec, homme d'affaires, 866, Latou-tvlle.(iilles Jobin.photograveur.680, Sutherland, rt Georges Bourl>cau.fonctionnaire.575, Sl-(ialiricl.tous trois de Quéliec.pour les objets suivants: Former et exploiter un club social et sportif, \u2022cm- le nom de « Club social et s|>ortif Le Chevalier .I.c montant auquel est limitée la valeur des liiei.- immobiliers que peut acquérir et posséder la cor|h.ration.est de 825.000.Le >iège social de la Corporation est 411.rue St-Vallier ouest, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la prorince.Raymond Douville.l'.VH.Vo 2124-68 La Compagnie commerciale d'enlèvement «le rebuts liée Commercial Refuse Collector Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l.oi des coDipagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a aceorili*' «les lettres patentee, en date du 29e jour d'avril 1068, constituant en corporation: Dama se Brissettc.243, rue Marie-Rose.André St-Jncqucs, 154.rue d'Anjou, tous deux avocats, de Longucuil, et l'icire Robichaud.comptable.1783, Walnut, Laflèche, pour les objets suivants: l'aire l'enlèvement des vidanges et rebuts, sous le nom de « La Compagnie commerciale d'enlèvement de rebuts ltée \u2014 Commercial Refuse Collector Company Ltd.».avec un capital total île 8-10.000, divisé en 400 actions ordinaires «le 1100 chacune.I.c siège social de lu compagnie est 27, rue Hiiiiond.Jacques-Cartier, district judiciaire de Montréal.Le tout-secrétaire d» la prorince, Raymond Douville.25015-o 1979-68 La Compagnie de développement touristique des Iles ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation : Paul-Emile Arseneau, gérant, Pointe-Basse, Alphonse-J.Arseneau, directeur d'école, Gérard Richard, commis, tous deux de Havre-aux-Maisons, J.-Octave Turbide, gérant, René Chevarie, fonctionnaire, Euclide Arseneau, gérant, et Edmond Cyr, camionneur, ces quatre derniers de Dunc-du-Sud, Iles-de-la-Mudelcine, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, auberges et restaurants, sous le nom de < La Compagnie de développement touristique des Iles ltée », avec mi capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.The head office of the corporation is at Maria, judicial district of Bonaventure.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2061-68 Club social et sportif Le Chevalier Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, bearing date the 10th day of May.l'.lliN.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Magclla Dolbec, businessman, 355 Latourelle, (idles Jobin, photo-engraver, 680 Sutherland, and Georges Bourbeau, civil servant.575 St-Gabricl, all three of Québec, for the following purposes: To form and operate a social and sports club, under the name of \"Club social et sportif Le ( Ihevalier\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $25.000.The head oflice of the corporation is at 411 St-Valher St.West.Québec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 2124-68 La Compagnie commerciale d'enlèvement de rebuts ltée Commercial Refuse Collector Conipuny Ltd.Notice is given that under Part I of the Comimnics Act.letters patent.Ix-aring date the 291 h day of April.1908.have Ix-cn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Damase Brissette, 243 Marie-Rose St.André St Jacques.I.VI d'Anjou St.both advocates, of Longucuil.and Pierre Robichaud, accountant.1783 Walnut.I,allèche, for the following purposes: To remove garbage and refuse, under the name of \"La Compagnie commerciale d'enlèvement de rebuts liée \u2014 Commercial Refuse Collector Company Ltd.\" with a total capital stock of 840.000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 27 Hémond St., Jacques-Cartier, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1979-68 La Compagnie de développement touristique des Iles ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul-Emile Arseneau, manager, Pointe-Basse, Alphonse-J.Arseneau, school director, Gérard Richard, clerk, both of Havre-aux-Maisons, J.-Octave Turbide, manager, René Chevarie.civil servant, Euclide Arseneau, manager, and Edmond Cyr, truck-driver, the latter four of Dunc-du-Sud, Magdalen-Islands, for the following purposes: To operate hotels, motels, inns and restaurants, under the name of \"La Compagnie de «lévcloppe-ment touristique des Iles ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. 3324 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100- année, n° 25 Le siège social de la compagnie est à Havrc-aux-Maisons, district judiciaire de Gaspé.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1897-08 Armand C.Comtois inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de mars 1968, constituant en corporation: Pierre Durand, 4027, Vendôme, Michel Dagenais, 383.Ste-Catherine, tous deux avocats, et Ange-Marie Boivin, secrétaire, fille majeure usant de ses droits, 6460, Erncst-Lavigne, tous trois de Montréal, pour les objets suivant i: Exploiter des hôtels, motels, restaurants et magasins et faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et île placement, sous le nom de « Armand C.Comtois inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Boucher-ville, district judiciaire de Montréal.Le sous-sccréiairr de la province, Raymond Douville.25015-o 1399-68 Le Coq de Bruyère inc.Avis est donne qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour île mai 1968, constituant en corporation: Alfred Yigcant, rue Brassard, Nicolet, Robert Lajoie, 470, Terrasse Rer-Iinguet, Trois-Rivières, François Lajoie, 4270, Notre-Dame, Trois-Rivièrcs-Ouest, tous trois avocats, Isabelle Vigneau, et Lucettc Vigneau, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de 330, de la Cathédrale, Trois-Rivières, pour les objets suivants: Faire affaires comme marchands de volailles, sous le nom de < Le Coq de Bruyère inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1912-68 Cosmos Restaurant Montreal Inc.Restaurant Cosmos Montréal inc.Avis est donné qu'en vertu de In première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de mai 1968, constituant en corporation: Gerald Poslelnick, 73.r>5, Ostclj Crescent, Brahm L.Campbell, 4530, chemin de la Côte des Neiges, tous deux avocats, et A.Sutherland, secrétaire, épouse de feu John Sutherland, 1641, rue De Maisonncuve, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un restaurant, sous le nom de « Cosmos Restaurant Montreal Inc.\u2014 Restaurant Cosmos Montréal inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est i\\ Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015 1386-68 The head office of the company is at Havrc-aux-Maisons, judicial district of Gaspé.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Prorince.25015 1897-68 Armand C.Comtois inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 27th day of March, 1968, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Durand, 4027 Vendôme, Michel Dagenais, 383 Ste-Catherine, both advocates, anil Ange-Marie Boivin, secretary, spinster of the full age of majority in use of her rights, 0460 Erncst-I.avigne, all three of Montréal, for the following purposes: To operate hotels, motels, restaurants ami stores, anil to carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Armand C.Comtois inc.\".with a total capital stock of 840.000, divided into I.O00 common shares of $10 each.The head office of the company is at Boucher-ville, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1.39MB Le Coq de Bruyère inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Alfred Yigcanl, Brassard St., Xicohl, Robert Lajoie, 470 Terrasse Berlingiiet, Trois-Rivières, Francois Lajoie, 4270 Notre-Dame, Trois-Rivicres-West, all three advocates, Isabelle Vigneau, and Lucettc Vigneau, the taller two secretaries, spinsters of the full age of majority, of 330 de la Cathédrale, Trois-Rivières, for the following purposes: To carry on business as poultry merchants', under the name of \"Le Coq de Bruyère inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Raymond Dduvh.i.i:.Assistant Secretary of the Province.25015 1912-6S Cosmos Restaurant Montreal Inc.Restaurant Cosmos Montréal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent bearing date the 13th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: (ierald Postelnick, 7355 Ostell Crescent, I i rali m L.Campbell, 4530 Côte des Neiges Road, both advocates, and A.Sutherland, secretary, wife of the late John Sutherland, 1641 De Maisonncuve Street, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Cosmos Restaurant Montreal Inc.\u2014 Restaurant Cosmos Montréal inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 4,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-0 1386-6S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3325 Leo Côté transport inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la l.\"i des compagnies, le licutenant-piiivcrncur de la province a accordé des lettres paient es, en date du 18e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Léo Côté, Alain Côté, tous ileux camionneurs, et Diane Côté, \u201ernl:iire, fille majeure, tous trois de 4190, Notre-Dame ouest, .Montréal, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie de transport, .un- le nom de « Léo Côté transport inc.avec un capital total de 840,000, divisé en 20.000 actions ordinaires de 81 chacune et en 2.000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 4190, rue Notre Dame ouest, Montréal, district judiciaire île Montréal.Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douville.25015* 1791-08 I oiivrette & Provost (Mauricic) ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I.oi des compagnies, il a élé accordé, par le lieutenant-gouverneur de lu province, des lettres patentes, en date du 1er avril 1908.autorisai l la fusion de « Conrad Lajoie (1904) ltée », constituée par lettres pateides en date du 28 août 1904.et Magasins Ilegal Stores inc.», constituée par lettres patentes en date du 11 sep-leinl.re 1950.toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu de ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: l'aire le commerce en gros cl au detail d'épicerie, ntM le nom de « Couvrettc & Provost (Mauricic) lté» .avec un capital total de $500.000, divisé en 20.000 actions ordinaires d'une valeur au |iair île $10 chacune et en 3.000 actions privilégiées d'une valeur au pan de 8100 chacune.I.c -iège social de la compagnie est à Cap-de-lii Madeleine, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond 1)oi vii.i.k.250154 1450-58 \u2014 1422/15 Créations Lydie Vialetto inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 1er jour «le mai 1908, constituant en (-orporation: Mark Rosenstein, 5003, avenue Lacombc, Jacques Lemattre-Auger, sl|i-'.Drolet, tous deux de Montréal, et Alexander S.Kouigsberg, 2378, rue Frenctte, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivant-: l.a confection et le commerce de vêtements et d accessoires vestimentaires, sous le nom de « Créations Lydie Vialette inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'ans valeur au pair de $10 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 2012-68 Crépin Investments Inc.Les Investissements Crépin inc.Léo Côté transport inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, beariiig date the 18th day of April.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Léo Côté.Alain Côté, both truck-drivers, and Diane Côté, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 4190 Notre-Dame West, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transportation company, under the name of \"Léo Côté transport Inc.6, with a total eupital stock of $40,000, divided into 20.000 common shares of $1 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4190 Notre-Dame street West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25015 1791-68 Couvrettc & Provost (Mauricic) ltée Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province was pleased to grant letters patent dated April 1.1968.authorizing the amalgamation of \"Conrad Lajoie (1964) ItiV, incorporated by letters patent dated August 28, 1964.and \"Magasins Ilegal Stores inc.\", incorporated by letters patent dated September II, 1959.all the aforementioned letters patent having licen issued pursuant to the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To deal in the grocery wholesale and retail business, under the name of \"Couvrettc & Provost (Mauricic) ltée\", with a total capital stock of 8500.000.divided into 20,000 common shares of a par value of 810 each and into 3,000 preferred shares of a par value of 8100 each.The head office of the company is at Cap-dc-la-Madclcine.judicial district of Trois-Rivières.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1456-68\u2014 1422/15 Créations Lydie Vialette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of May, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Mark Rosenstein, 5003 Lacombe Avenue, Jacques Lemaltre-Augcr, 8462 Drolet, both of Montreal, and Alexander S.Konigsberg, 2378 Frenette Street, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clotliing and related accessories, under the name of \"Créations Lydie Vialette inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided in In 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred sliares of a par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 2012-68 Crépin Investments Inc.Les Investissements Crépin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of May, 1968, have been issued by the Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres 3326 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968.100' année, n\" 25 patentes, en date du 14e jour de mai 1968, constituant en corporation : Gaspard Crépin, commerçant, Juliette Barrette, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Ga.s-pard Crépin, tous deux de Domaine Crépin, Grande-Ile, Pierre Crépin, commerçant, et Denise Themens, ménagère, épouse contractuellement séparée de biens dudit Pierre Crépin, ces deux derniers de 43, Armand-Frappier, Salaborry-dc-Valleyfield, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Crépin Investments Inc.'\u2014Les Investissements Crépin inc.», avec un capital total de §100,000, divisé en 100 actions ordinaires de S10 chacune et en 9,900 actions privilégiées de SI0 chacune.Le siège social de la compagnie est à Salabcrry-de-Vallcyfield, district judiciaire de Beauliarnois.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2206-68 Dan-A-Di inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur île la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de mai 1968, constituant en corporation: Paul Vczina, 7010, Place Mont-Clair, Charlcsbourg, Louis Rémillanl, 1169, Brown, tous deux avocats, Micheline ( 'aron, 65, Aberdeen, et Bibianc Rioux, 1615, île Nivcr-ville, cesdeux dernières secrétaires, filles majeures, ces trois derniers de Québec, pour les objets suivants: Exploiter une tabagie, sous le nom de « Dan-A-Di inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 350 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Charles-bourg, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2112-68 David Press Inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Nelson David, imprimeur, Barbara Stanton, ménagère, épouse dudit Xclson David, tous deux de 7615, Bois Chatel, Saint-Léonard, et Sadie George, ménagère, veuve de Michael David, 6757, Henri-Julien, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un atelier d'imprimerie et faire le commerce de boîtes de carton, de papeterie, étiquettes et fiches, sous le nom de « David Press Inc.», avec un capital total de 840,000, divise en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 85 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015 2034-68 Raymond David inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour d'avril 1968, Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gaspard Crépin, trader, Juliette Barrette, housewife, wife contractually separate as to property of said Gaspard Crépin.lxdhof Domaine Crépin, Grande-Ile, Pierre Crépin, trader, and Denise Themens, housewife, wife contractually separate as to property of said Pierre Crépin, the latter two of 43 Armand-Frappier, Salaberry-de-VaUeyfield, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Crépin Investments Inc.\u2014 Les Investissements Crépin inc.\", with a total Capital stock of 8100,000, divided into 100 coin-mon shares of $10 each ami into 9,900 preferred shares of $10 each.The head office «>f the company is at Salaberry-dc-Valleyfield, judicial district of Bcauharnois.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 L'L'dii-iis Dau-A-Di inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 8th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Vé/.ina, 7010 Place Monl-( lair, Charlcsbourg, Louis Hémillard, 1109 Brown, both advocates, Micheline Caron, 65 Aberdeen, and Bibiane Rioux, 1645 de Xiverville, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, the latter three of Quebec, for the following purposes: To operate a tabacconist store, under the name of \"Dan-A-Di inc.\", with a total capital slock of $40,000, divided into 5,000 common shares «,f >1 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company is at Charlcsbourg, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2112-6S David Press Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Nelson David, printer, Barbara Stanton, housewife, wife of the said Nelson David, both ol 7615 Bois Chatel, Saint-Léonard, ami Sadie George, housewife, widow of Michael David, 675\" Henri-Julien, Montreal, for the following purposes: To carry on business as general printers and to deal in paper boxes, stationery, tags and labels under the name of \"David Press Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $5 each and 350 preferreil shares of a par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 2034-68 Raymond David inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 22, IOCS, Vol.100, No.2f> 3327 constituant en corporation: Gisèle Roycr, 6041, Émilc-Nelligaii, Henriette Laforest, 2139, rue Kicolct, toutes deux secrétaires, fdles majeures, ,.| Marc Bourgeois, avocat.4050, rue .lauron, t,nis Iroisdc Montréal, |k>ur les objets suivants : Agir comme conseiller en organisation et administration financière, sous le nom de « Raymond David inc.', avec un capital total dc 140,000, divise en 50 actions ordinaires de S100 ductule et en 3,500 actions privilégiées de S10 chacune.Le >iège socinl de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire dc la prorince, Raymond Douville.2501&4) 1598-68 Patrick Dclisle & fils inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies, le lieutcnant-(¦oiivcriicur de la province a accordé des lettres patentee, en date du 30e jour d'avril 1908, constituant en corporation: Alphonse Dclisle.plombier.4278, Des Cyprès.Orsainville, Lucien Rcli-lc.électricien.395.des Chênes est.app.2, et l'airick Dclisle, plombier.385.3e rue.its deux derniers de Quélicc.\\mir les objets suivants: Faire affaires comme électriciens, entrepreneurs en plomberie, chauffage et en réfrigération, sous le nom de * Patrick Dclisle & fils inc.¦\", avec un capital total de $50.000, divisé en 4.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.I.c siège socinl de la compagnie est 4278.Des Cyprès.Orsainville.district judiciaire de Quélicc.Le snus-secrétaire de la prorince, Raymond Doi VILLE.250154 1724-68 Dcry Express Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour dc mai 1968, constituant en cor|>oration: Gilles (ïauthicr, 704, 3e rue.Jacques Gauthier.1284, rue Laml>ort, Ion- deux camionneurs, et Jean Gauthier, gérant, 241\").rue Coutu, tous trois dc Shawiniguu, |k»ur le- objets suivants: Faire affaires comme coni|>aguic de transi>ort, -oils le nom dc « Dery Express Inc.», avec un capilal divisé en 800 actions classe « A » sans valeur nominale, 200 actions classe « B » sans valeur nominale et en 1,440 actions privilégiées de 925 chacune.Le siège social de la compagnie est à Shawiniguu, district judiciaire dc Saint-Maurice.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.250I5-O 1096-68 pormtingj Gisèle Royer, 6041 Émilc-Xelligan, Henriette Laforest, 2139 Nicolet Street, both secretaries, spinsters of legal age, and Marc Bourgeois, advocate, 4050 Jauron Street, all three of Montreal, for the following purposes: To act as consultants in organization and financial management, under the name of \"Raymond David inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 50 common shares of 8100 each and 3.5O0 preferred shares of 810 each.The bead office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.R a ym on d Dot\" ville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1598-68 Patrick Dclisle & fils inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent.licuring date the 30th day of April, 1908.have liecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor-poraling: Alphonse Dclisle, plumber, 4278 Des Cyprès.Orsainville, Lucien Dclisle.electrician, 395 Des Clicnes.east.Apt.2.and Patrick I b'lisle, plumber.385, 3rd Street, the latter two of Québec, for the following purposes: To carry on business as electricians and plumbing, healing and refrigeration contractors, under the name of \"Patrick Dclisle & fils inc.\", with a total capital stock of 850.000.divided into 4.000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at 4278 Des Cyprès, Orsainville, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1724-68 Dcry Express Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act letters patent, bearing date the 1st day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Gauthier, 704, 3rd Street, Jacques Gauthier.1284 Lambert Street, both truckers, and Jean Gauthier, manager, 2445 Coutu Street, all three of Shawinigan, for the following purposes: To carry on business as trans|>ort company, under the name of \"Dery Express Inc.\", with a capital stock divided into 800 class \"A\" shares without nominal value, 200 class \"B\" shares without nominal value and into 1,440 preferred shares of $25 each.The bead oflice of the company is at Sliawi-nigan, judicial district of Saint-Maurice.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1096-68 Les Développements Parc Québécois inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Phillip Saul Lccker-njan.propriétaire d immeubles, 4866, Cote (les \u2022Neiges, app.1071), Montréal, Léo Rémillard, \u2022dinuiistrateur.2133, Notrc-Dame-dc-GrAce, Jac-ques-Cartier, Israel Pcrvin, 5776, Rand, Côte Saint-Luc, et Morris Leckerman, 1455, Normandie.Laval, ces deux derniers négociants, pour les objets suivants: Les Développements Parc Québécois inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of April, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Phillip Saul Lcckerman, real estate investor, 4866 Côte des Neiges, Apt.107D, Montreal, Léo Rémillard, executive, 2133 Notre-Dame de Grace, Jacques-Cartier, Israel Pervin, 5776 Rand, Côte Saint-Luc, and Morris Leckerman, 1455 Normandie, Laval, the latter two merchants, for the following purposes: 3328 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 19GS, 100' année, n\" 25 Exploiter une entreprise d'immeuble et dc construction, sous le nom dc « Les Développement Parc Québécois inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 1999-08 To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Les Développements Parc Quéliecois inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 6,000 common shares of a par value of $1 each and 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Mont-real, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province 25015-o 1999-6S Les Développements Parc St-Laiirent inc.Avis est donné (pi'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des let i res patentes, en date du 20e jour d'avril liltiS, constituant en corporation: Philip Saul Leckerman, investisseur d'immeubles, 4800 Cède des Neiges, app.107-D, Montréal.Léo Rémillard, administrateur, 2133, Xotrc-Dainc-dc-Grace.Jacques-Cartier.Israel Pervin.5770.avenue Rand, Côte Saint-Luc.et Morris Ix-ckerman, 1455.boulevard Xoniianilie, Laval, ces doux derniers marchands, |x>ur les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de construction, d'immeubles et «le placements, sous le nom dc « Let Déwkropementa Parc St-Laurent inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3.500 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la coni|Nignie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Doi ville.25015 1920-08 Dcweko lice De we ko Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 9e jour de mai 1908.constituant en corporation: Gertrude Belley, fleuriste, fille majeure.100, rue Muisonneuvc, Georgette Simnrd, secrétaire, fille majeure.88, rue des Érables, et Claude Belley.fleuriste.104, rue Maisonneuvc.tous trois de Jonquièrc, pour les objets suivants: Paire le commerce de tous produits, articles et marchandises, sous le nom de « Dcweko ltée \u2014 Dcweko Ltd.».avec un capital total de S40.1XX).divisé en 4.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune Le siège social de la compagnie est 100, rue Maisonneuvc, Jonquièrc, district judiciaire dc Chicoutiini.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2085-08 lis Développements Parc St-Laurent inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent.Ix-aring date the 20th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Phillip Saul Leckerman, real estate investor, 4.Sliti ( Vite des Xcigcs, apt.107-1*.Montréal.Leo Rémillard.executive, 2133 Xolre-Dame-dc-GrAce, Jacques-Cartier.Israel Pcrvin.5770 Rand Avenue.Côte Saint-Luc.and Morris Leckerman, 1455 Normandie Boulevard.Laval the latter two merchants, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Les Développements Parc St-Laurent inc.\", with a tidal capital stock of $40.000, divided into 5.000 common shares of $1 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head ollicc of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Doiville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 1930-68 Dcweko ltée Dcweko Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of May.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gertrude Belley, florist, spinster of the full age of majority.100 Maisonneuvc Street, Georgette Simard.secretary, spinster of the full age of majority.88 des Erables Strut, and Claude Belley, florist, 104 Maisonneuvc Street, all three of Jonquièrc, for the following purposes: To carry on business dealing in all products, articles and merchandise, under the name of \"Dcweko ltée \u2014 Dcweko Ltd.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at H'O Maisonneuvc Street, Jonquièrc, judicial district of Chicoutiini.Raymond Doiville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 2085-OS Diversified Lighting Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de mai 1968, constituant en corporation: Edward Grunikcwic/., administrateur, 8500, 9e Avenue, Saint-Michel, Daniel Kingstone, 4985, Iona, Montréal, et Dionysia Zcrbisias, 5525, Wcstbourne, Côte Saint-Luc, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Diversified Lighting Industries Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of May, 1968, have taen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Edward Grunikewicz, executive, 8500, 9th Avenue, Saint .Michel, Daniel Kingstone.4985 Iona, Montréal, and Dionysia Zcrbisia-, 5525 Wcstbourne, Côte Saint-Luc, the latter two advocates, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3329 I ' ¦ \u2022 111.-1- des installations d'éclairage électrique d'ornementation et en faire l'entretien, sous |onom de* Diversified Lighting Industries Ltd.», avec un capital total dc $40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2.10 lô 2111-68 I.c Domaine Normandie inc.Avis est donné qu'en verlu de In première partie de lu Loi des compagnies, le lient count-gouverneur de la province a accordé des lettres pale nies, en date du 1er jour de mai 1908, constituant en corporation: Cécile Bernard, 382, St-Viateur, Denise Duquette, 438, St-Jacqucs, et Jocelyne Lacoste, 113, Clarence, toutes trois secrétaires, filles majeures, de Granhy, pour les ohjets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et île construction, sous le nom de « Le Domaine Normandie inc.», avec un capital total de $10.1100.divisé en 40,000 actions ordinaires dc $1 chacune.I.c siège social de la compagnie est il Lac Schoycr, Montpellier, district judiciaire de Hull.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.250154 2004-68 Donald h.Donald Productions Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur «le la province a accorde des lettres patentes, en date du 1er jour de moi 1968, constituant en corporation: Donald IL Tarlton, |>répo»é à la distribution des billets pour spectacles, 3565, avenue Lornc, app.707, Montréal, Max Sidney Kaufman, avocat et conseil en Loi de la reine, 574, Clarcmont, Wcstmount, et Sydney 11.ScderolT, avocat, 80, avenue Crcstwood, Montréal-ouest, pour les objets suivants: Agir comme intermédiaires pour l'engagement d'artistes pour spectacles de théâtre ainsi que des artistes commerciaux, sous le nom dc « Donald K.Donald Productions Ltd.», avec un capital loi.il de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de MO chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est il Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 2001-68 Norman Donuts Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de mai 1968, constituant en corporation: Normand Bérubé, courtier d'assurances, Renée Hobitaille, ménagère, épouse contractuellement séparée dc biens dudit Normand Bérul>é, tous deux de 10240.Parthenon's.Montréal-Nord.Maurice Gauthier, administrateur, 4245, St-Hul)crt, et Solanges Laiwrlc, secrétaire, épouse contractuellement séparée de tiens de Vvon Perras.10930.Frigon, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: To carry on business as manufacturers and installers of architectural electrical lighting and to provide maintenance therefor, under the name of \"Diversified Lighting Industries Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 2111-68 le Domaine Normandie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 1st day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Cécile Bernard, 382 Saint-Viatcur, Denise Duquette, 438 Saint-Jacques, and Jocelyne Lacoste, 113 Clarence, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, of Granby, for the following purposes: To carry on business as a real estate and building company, under the name of \"Le Domaine Normandie inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Lac Schoyer, Montpellier, judicial district of Hull.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2004-68 Donald K.Donald Productions Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent bearing date the 1st day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Donald R.Tarlton, entertainment booking agent, 3565 Lome Avenue, Apt 707, Montreal, Max Sidney Kaufman, advocate and Queen's Counsel, 574 Clarcmont, Wcstmount, and Sydney B.Sederoff, advocate, 80 Crestwood Avenue, Montreal West, for the following purposes: To carry on the business of a booking agency for entertainers, theatrical shows and commercial artists, under the name of \"Donald K.Donald Productions Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of tlm Province.25015-o 2001-68 Norman Donuts Ltd.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of May, 1968.have l>een issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Normand Bérubé.insurance broker, Renée Robitaillc, housewife, wife contractually separate as to property of said Normand Bérubé, both of 10210 Partheiiais, Montreal-North, Maurice Gauthier, director, 4245 St-Hubert, and Solanges Laperle.secretary, wife contractually separate as to property of Yvon Perras.10930 Frigon.the latter two of Montreal, for the following purposes: :mo GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'ÉllEC.22 juin 1968, 100' année, n\" 25 Faire affaires comme confiseurs, sous le nom de «Norman Dnnuts Ltd.», avec un capital total de 130,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI cliaeunc et en 2,500 actions privilégiées «le S10 chacune.I,e siège social île la compagnie est 10240.rue l'art hennis, Montréal-Nord, district judiciaire de Moid real.Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Dor vii.i.k.36015m 2117-08 To carry on business us conlectioncrs.under the name of \"Norman Donuts Ltil.\".with a total capital stix'k of 680,000, divided into 5,000 commoii sliures of $1 each ami into 2.500 pre.fcrred shares of $10 each.The head oflice of the company is at 1112-1(1 Purlhcnais Street.Montreal-North, judicial district of Montreal.Raymond Dor vii.i.k.Assistant Secretary of the Prorince.25015 2117-08 C.Doyon T.V.(Sherbrooke) inc.Avis est lionne qu'en vertu de la première partie de la Dii des compagnies, le lieiiteiiaut-gouverneur de la province a accordé des Ici 1res patentes, en rat ion : Grégoire Doyon.électronicien, Monique Bi/.ier.ménagère, épouse séparée de biens dudit Grégoire Doyon.el Réal Bîaier, tisseur, tous trou de 130, rue Alençon, Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme elect riciens cl faire le cniiuncrcc et l'eutn-tien de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom «le « (i.Doyon TA'.(Sherbrooke\") inc.», avec un capital total «le 840.000.divisé-en 2.000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 2.000 actions privilégiées de $10 chacune.\\a' siège social «le la compagnie est OSN, ( 'oiiseil, Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Dim vii.i.k.25015-o 1870-08 Duvernny Marina inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gOUVemeur de h province a accordé «les lettres patentes, en date du 1er jour de mai 1068.constituant en cornoration: Guy-E.Boisvert, 4976, (¦Icneairii.(i.Harold l'ickel.47.Arlington, tous deux île Montréul, f \"(¦\u2022 Doyoa T.V.(Sherbrooke) inc.\", with a total capital stock of 140.000.divided into 2.000 common shares of $10 each and into 2.000 preferred shares «if 810 each.The head office of the company is at OSS Conseil.Sherbrooke, judicial district of St.François.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretary of the Prorince.35016 1870418 Duvernuy Marina inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act.letters patent, bearing dale the 1st day of May.1008.Imve l>ccn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy-E.Boisvert, 4070 Glencairn.G.Harold Pickci.47 Arlington, both of Montreal, and Claude Boisvert.1505 Moore.Laval, all three advocates, for the following puqwses: To operate hotels, taverns, inns, restaurants and marinas, under the name of \"Duvernuy Marina inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 1,000 common shares of $10 eueh and 300 preferred shares of $100 each.The head ofliee of the coiii|>any is at Laval, judicial district of Montreal.Raymond Dorviu.k.Assistant Secretary of the Prorince.25015 3039-68 Écurie Québec inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, Uicorpo-rating: Nicole Viau, 0834 Des Écores, Diane Sl-Hilaire, 0356 Iberville St., and Ginette Murray 2351 Bcllechasse St., all three secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, f»r the following purposes: To operate a racing vehicle stable, under the name of \"Écurie Québec inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of a par value of $10 each and 1,500 preferred shares of a par value of $10 each. QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.June 22.IMS.Vol.100.No.25 3331 Le siège social de la compagnie est 1365, rue Du Collège, Suint-Laurent, district judiciaire dc Montréal.Le sous-seerftaire de ta province, Raymond Douville.2501 ô-o 1996-68 Edifranee Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de lu Loi des compagnies, le liciitcnant-purerneUT de la province a accordé des lettres patentes, en date du tic jour de mai 196S, constituant en corporation: Frederick Gautzsch, homme d'affaires, 217, Hyman Drive, Dollurd-des-Oiineaux, Michael Coomlies, homme d'affaires, et F.dith Fortin, ménagère, épouse dudit Michael Coomhcs, ces deux derniers de 179, avenue Wcslcliffe, Pointe-Claire, |>our les objets suivants: Contestionner des blouses, rohes et tous autres articles vestimentaires jxnir dames, en faire le commerce, sous le nom de « Kdifrance Inc.», avec un capital total de 3100,000, divisé en 750 actions ordinaires de SHX) chacune et 200 actions privilégiées de SI25 chacune.I.c Nège social de la compagnie est 54, de la Fabrique, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-scerttaire de la province, Raymond Don vii.i.k.25015 2081-68 Les Entrepôts St-André ltée Avis ,,t donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutcnant-piuveriiciir de la province a accordé des lettres patentes, ,-n date du Oe jour de mai 1968, constituant en cor|n>ration: Pierre Godhout, avocat et Conseil en Loi de la reine, 50, Les Érables, Denis Moreau, courtier en transport, 440, Croissant de Pans, tous deux de Laval, et Ghislaine Lacha-pclle, secrétaire, fille majeure, 12205, Lagauche-tiére.I'ointe-aux-Trembles, |K»ur les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de trans|>ort, sous le nom de « Les Entrepots St-André ltée», avec un capital total de 810,000, divisé en 400 actions ordinuires de S100 chacune.I.c siège social de la compagnie est 1315, boule-yard de Maisonneuvc ouest, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c tous-secrétaire de la province, Raymond Douvim.e.2501.-.o 1986-68 Les Entreprises A.G.P.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première psrtic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mai 1968, Constituant en corporation : Georges-Yvon Gouin, 780, Davaar, Outremont, Guy-Paul Gcncst, 3152, rendait, tous deux avocats, et Paul Chevalier, étudiant, 5291, McKenna, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Fuire affaires comme nettoyeurs, presscurs, teinturiers, buandiers et faire la réparation dc ^'elements, tissus, marchandises et ameublements \"Je maison, sous le nom dc « Les Entreprises A 'jl'.inc.», avec un capital total de $40,000, 'hvi-e en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune Le siège social dc la compagnie est à M.ni Rolland, district judiciaire de Terrebonne.The head office of the company is at 1365 Du Collège St., Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1996-68 Edifranee Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 0th day of May.190S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Frederick Gautzsch, businessman, 217 11> 111:111 Drive, Dollard-des-Ormeaux, Michael Coornbes, businessman, and Edith Fortin, housewife, wife of the said Michael Coornbes, the latter two of 179 Westcliffe Avenue, Pointc-( 'laire, for the following purposes: To manufacture and deal in women's blouses, dresses and all other women's apparel, under the name of \"Edifranee Inc.\", with a total capital stock of $100.000, divided into 750 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $125 each.The head office of the company is at 54 de la Fabrique, Quebec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-0 2081-68 I-es Entrepots St-André ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of May, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Godliout, advocate and Queen's Counsel, 50 Les Érables, Denis Moreau, forwarding agent.440.( 'roissnnt de Paris, both of Laval, and Ghislaine Lachapelle, secretary, spinster of the full age of majority, 12205 Lagauchetière, Pointe-aux-Trcmbles, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Les Entrepots St-André ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head ollice of the company is at 1315 de Maisonneuvc boulevard West, Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1986-68 Les Entreprises A.G.P.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges-Yvon Gouin, 790 Davaar, Outre-mont, Guy-Paul Genest, 3152 Fendait, both advocates, and Paul Chevalier, student, 5291 McKenna, the two latter of Montréal, for the following purposes: To carry on business as cleaners, pressera, dyers, launderers, and to repair clothing, woven, goods, merchandise and home furnishings, under the name of \"Les Entreprises A.G.P.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Mont-Holland, judicial district of Terrebonne.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1418-68 Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2o015-o 1418-68 3.332 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 Les Entreprises A.Ricci inc.Avis est ilonné qu'en vertu de la première pjirtie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour «le niai 1968.constituant en corporation: Albert Ricci, homme d'affaires, Réjcanne (îoheil, ménagère, é[Kiusc dudit Albert Ricci, et Dominique Ricci, garçon de table, tous trois de 7659, Millet, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Exploiter des hotels, tavernes, aulicrgcs et restaurants, sous le nom de « Les Entreprises A.Ricci inc.», avec un capital total dc 8-10,000, divisé en 4,000 actions ordinaires onne.Raymond Dor ville, Assistant Secretary of the I'roriucr.25015 1887-68 Les Entreprises robustes inc.Robust Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Richard Garcau, advocate, 2255 Ben- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 23, 1908, Vol.100, So.25 8888 S55 Rciijamin-Sulte, Madeleine Tcssicr-Lavigne KCrélaire, fille majeure, 1610, rue St-IIuhcrt, d |,n Ile M.Parent, secrétaire, épouse séparée dc liieiis de .1.-1.Parent, 2449.avenue Benny, tous Hois de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un restaurant, sous le nom dc « Les Est reprisée robustes inc.\u2014 Kobust Enterprises Inc.avec un capital total de 140,000, divisé on I.IHHI actions ordinaires d'une valeur au pan île s| chacune et 3.900 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $10 chacune.I.e nèfle BOcial de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.c tout-secrétaire dc la province, Raymond DOUVILLE.25015 2048-68 Entreprises 407 inc.Avis est ilonné qu'en vertu de la première parti'- de la Loi des compagnies, le lieutcnant-piiiM-rncur de la province a accordé des lettres palci 'es.en date du 14e jour de mai 1968, constituant en corporation: Henri Madclein.courtier d'assurances, 198.Denonville.Francois (ioilbnut.avocat.1274.Éthier.tous deux dc [aval et Guy Portier, notaire.240.Lazard.Mont-Royal, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble et de i.struct ion.sous le nom de « Entreprises 407 inc.avec un capital total de $40.000.ilivi-é en 1.000 actions orilinaires de $10 chacune et en .'100 actions privilégiées de $100 chacune.Le nèfle social de la com|>agnie est 407.Ixwlc-vard Labelle, Laval, district judiciaire de Montréal Le sous-secrétaire tic la prorince.Raymond Doi vii.i.k.25015-O 1877-08 Etna Holding ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-BOOVemeUf de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de mai 190.8, constituant en corporation: Francesco unci, 7112, Mobon, Leonardo Scalia, 5686, (lark, tous deux île Montréal, et Giovanni liattista (\"iiffaro.6570, l/c Becquet, Saint-Léonard, tous trois hommes d'affaires.|k»ur les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble, île const ruction et de portefeuille, sous le nom de « Etna Holding Ltd.», avec un capital total de $40.000.divisé en 1.200 actions ordinaires dc si chacune et en 3.880 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doiville.250l.-,-o 1991-68 Ferraro inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnant-(OUVerneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai 1908, constituant en corporation : Pierre Lalande, avocat, I narlottc Dubois, ménagère, épouse séparée de biens dudit Pierre Lalande, tous deux dc 1, 'lace Laval, Laval, et Ginette Huncaiilt, secrétaire, fille majeure, 7283, rue Berri, Montréal, pour les objets suivants: jamin-Sultc, Madeleine Tessier-Lavigne, secretary, fille majeure, 1610 St.Hubert Street, and Licttc M.Parent, secretary, wife separate as to property of J.-.L Parent.2449 Benny Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Let Entreprises robustes inc.\u2014 Robust Enterprises Inc.\".with a total capital stock of 840.000.divided into 1.000 common shares of the jwir value of $1 each and 3.900 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montréal.Il vvMONii Douville, Assistant Secretary of the Province, 2,')015-o 2046-68 Entreprises 407 inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 14th day of May.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri Madelein.insurance broker, 198 Denonville.Francois Gotlhout.advocate.1274 ftthier.both of Laval, and Guy Fortier.notary.240 Lazard, Mount Royal, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Eutreprises 407 inc.\".with a total capital stock of $40(100.divided into 1.000 common shares of $10 each and into 300 preferred shures of $100 each.The head office of the company is at 407 Labelle boulevard.Laval, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1877-68 Etna Holding Ltd.Notice is given thai under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of May.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Francesco leraci, 7112 Molson.Leonardo Scalia.5085 Clark.Iwth of Montréal, and Giovanni liattista Culfaro.5570 Le Becquet.Saint-Léonard, all three businessmen, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and holding company, under the name of \"Etna Holding Ltd.\", with a total capital slock of $40.000.divided into 1,200 common shares of $1 each and 3,880 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Haymoxd Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 1991-68 Ferraro inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1908, nave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Lalande, advocate, Charlotte Dubois, housewife, wife separate as to property of said Pierre Lalande, liotii of 1 Place Laval, Laval, and Ginctte Huneault, secretary, spinster of the full age of majority, 7283 Berri Street, Montréal, for the following purposes: 3334 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC.23 juin IMS, 100' annfe.n° 20 Faire affaires eoiiinie compagnie d'immeuble, de construction, de platement et de portefeuille (holding), sous le nom dc « Fcrraro inc.», avec un capital total dc $300.000.divise en 40 actions ordinaires de $100 chacune, 1.000 actions privilégiées classe \u2022 A >¦ de 81 chacune et en 2.950 actions privilégiées élusse « 11 » de $100 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est 3570.rue Jean-Talon est.Suint-Michel, district judiciaire de Montréal./.c sous-secrêtaire de la prorince.Raymond Douville.25015-O 1004-08 l'ilicr inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneiir de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de mai 1008.constituant en corporation: Pierre lteriiier.avocat.2175.des Intendants.Liliane (îervais.203.13e rue.et Ginette (iingras.434.d'Aiguillon, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Québec, pour les Objeta suivants: Faire des o|>ératiolis de prêta et placements de toutes sortes, sous le nom de « Fiber inc.avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le tout secretaire it la prorince, Raymond Douville.25015-o 2041-08 Fondation Familiale des Bourses d'Etudes inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de mai 1008.constituant en corporation sans capital-actions: Paul Bcrnicr.père dominicain.175.rue Grande-Allée ouest, Cécile Faguy.rentière, veuve de MarcTan-guay.942, rue Manrèsc, tous deux de Québec, et André Lavcrdièrc.notaire.2841.Delorimicr, Sainte-Foy.pour les objets suivants: Encourager et promouvoir le progèsde l'éducation au moyen de bourses d'études cl autre aide aux étudiants et aux universités canadiennes, sous le nom de « Fondation l'amiliale des bourses d'Etudes inc.».Le montant auquel est limitée lu Valeur des biens immobiliers que {x-nt acquérir et posséder la eor|wratioii.est de $10.000.Le siège social de la corporation est 040.rue St-Jcan, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.25015-o 1078-08 La Fondation Richelieu Montréal Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour d'avril 1908, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-L.Sansoucy, avocat, 1485, Rernard ouest, Montréal, Aimé I.aplanie, maître-ingénieur, 3495, de la Montagne, Montréal, (îérard-B.(îenest, administrateur, 543, Stuart, Montréal, Paul Guertin, gérant, 380, Wiseman, Montréal, Robert-A.I .a point.-, gérant, 208, Baherwood, Dollard-des-Ormeaux, Robert Baillargeon, ingénieur civil, 4710, Tonty, Montréal, Jean-Jacques Prud'homme, notaire, 5235, Borden, Montréal, Adclard (îroulx, médecin, 11400, James-Morrice, Montréal, Jean-C.Aubry, administrateur, 4460, To carry on business as a real estate, construction, invest ment and holding company, under the name of \"Fcrraro inc.\".with a total capita] stock of 1300,000, divided into 40 common share, of $100 each.1,000 preferred class \"A\" shares of $1 each and into 2,950 preferred class \"B\" shares of $100 each.The head oflice of the company is at Haiti Jean-Talon Street East.Saint-Michel, judicial district of Montréal.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretary of the I'm* inn.25015 196448 Fiber inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act.letters [latent, beuring date the 3rd day of May, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Bcrnicr.advocate.2175 de- Intendants.Liliane (iervais.203.13th Street, ami dinette (iingras.434 (l'Aiguillon, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Québec for the following purposes To carry on all kinds of loan ami investment operations, under the name of \"Fiber inc.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 4IKI common shares of $100 each.The bead ollice of the company is at Québec, judicial district of Québec.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretary of the Province, 25015 204148 fondation Familiale des bourses d'F.tudcs inc.Notice is given that under Pari III of tbe Companies Act.letters patent, bearing dale the 3rd day of May.190S.have been issued by tbe Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a cor|Miraliou without share capital: I'aul Bcrnicr.Dominican father.175 Grande-Allée St.West, Cécile Faguy.annuitant, widow of Marc Tailgliay, 042 Manrèsc St.both of Québec, and André Lavcrdièrc.notary.2841 Dcloriniier.St.Foy.for the following purposes: To encourage and promote progress in education by means of scholarships and other aid to students and Canadian universities, under the name of \"Fondation l'amiliale des Bourses d'Etudes inc.\".The amount to which the value of the Immovable property which the cor|s>ration may acquire and hold is to Is- bunted is $10.000.The head ollice of the corporation is at 040 St.John St.Québec, judicial district of Quebec.Raymond Dorvii.i.i;.Assistant Secretary of the Prorince.28015 I67S-0S La Fondation Richelieu Montreal Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 5th day of April, 1068, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jcan-I.Sansoucy, advocate, 1485 Bernard West, Montréal, Aimé I.aplanie, master engineer, 3495 de la Montagne, Montréal, (iérard-B.(îenest, administrator, 543 Stuart, Montréal, Paul (îuerlin, manager, 380 Wiseman, Montréal, Roberl-A.Lapointe, manager, 208 Raderwood, Dollard-des-Ormcaux, Robert Baillargeon, civil engineer, 4710 Tonty, Montréal, Jean-Jacques Prud'homme notary, 5235 Borden, Montréal, Adélard (îroiilx, physician, 11400 James-Morrice, Montréal, Jean-C.Aubry, administrator, 4460 Pie IX, Mont- QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, .lune 22.1968, Vol.100, No.25 3335 boulevard Pie IX, Montréal, Urbain Xantel, administrateur, 1472, Ontario est, Montréal, R : lî.Pouliot, directeur général, 1259, Herri, Montréal, .lean Tberien, imprimeur, 7S00, Plan Seuilly, Anjou, Pierre Vincent, directeur-gérant, 6403, 2e avenue, Montréal, J.-Gérard Oraiuville, directeur de ventes, 6041, des Angevin-.Anjou.Bernard Grégoire, directeur de relation- publiques, 10355, Ksplanade.Montréal, Guy Crevicr, administrateur, 760, Rochon, Saint Laurent, Roger Meunier, courtier.9957, Grande-Allée, Montréal, Jean Goulet, avocat, 5759, Déom, Montréal, Raymond-A.Robic, conseil en propriété Industrielle, 2100, Drum-nion.l.Montréal.Jacques Bernard, marchand, .V.V).\").Itrilli m.Montréal, Annand-L.(ïodin, directeur.9005.('hristo|)he-('olomb, Montréal, J.René Wilhelniy, commerçant, 306, Barton, Montréal, .1.-Bernard Lavigueur, ingénieur.71, Maphwooil.Montréal.René Paré, avocat, 535, Ontreinont.Montréal.Lionel Gascon, comptable ¦gréé, 7220, Sagard, Montréal.1.-Albert Char-bonneSU, secrétaire de promotion, Campagne led, ration du (irand Montréal.Montréal.Michel lîobillard.notaire, 0230.Châtelain.Montréal.Jean Lacroix, comptable agréé, 0930.9e avenue.Montréal, Joseph Germain, courtier, .\">!{_'.des Pins ouest, Montréal.Gérard Krigon, directeur général, 12212, Reauséjour, Montréal, Pierre Charest.administrateur.1664, Manitou, Uval, TrelFIé Boulanger, administrateur, 3833, Place Victor-Bourgeau, Montréal, Pcrnand Messier, industriel, 70S, Wiseman, Outremont, .1.-Paul llariteau, directeur général adjoint.77.St-Joscph ouest, Montréal, Paul Dumas, adminis-traleur.900, Rockland, Outremont, Lionel-A.Aiiilclte.courtier en assurances, 4665, Borden, Montréal, Pierre Gratton, courtier en valeurs, 101.Pierre-Davignon, Boucherville, Y von Hétu, directeur d'école, 5524, Bélanger.Montréal, et Pierre Lussier.commerçant.36, Hollywood, Oiilreinont, pour les objets suivants: l'Acrcer des activités charitables et plus particulièrement venir en aide à l'enfunce et à la jeunesse, sous le nom île « La Fondation Richelieu Montréal ».Le montant auquel sont limités les biens immo-biliers que la cor|k>rution peut acquérir et posséder, est de S1,000,000.Le siège socinl de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.ht sous-secrêtaire de la province, Raymond Dot; vim.k.25015-o 1814-68 Foyer dc Valcourt inc.A is est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes) en date du 9e jour dc mai 1968, constituant en cor|M>ration sans capital-actions: Alphonse-Raymond Bombardier, rentier, Laurent Dorais, gérant de département, Roland St-Picrrc, ingénieur, tous trois de rue Montcalm, Camille Rouillant, médecin-vétérinaire, 937, Montcalm, Uarcellin Bouthiller, gérant de département, rue SI-Joseph, Laurent Beaudoin, industriel, et André Marcoux, médecin, rue de l'Église, tous sept de Vsicourt, pour les objets suivants: Founder à des couples âgés et à des personnes âgées des deux sexes un foyer leur permettant dc vivre en toute sécurité et dans l'atmosphère d'un véritable esprit de famille, sous le nom de « Foyer de Valcourt inc.».réal, Crbain Xantel, administrator, 1472 Ontario East.Montréal, Roland li.Pouliot, general director, 1259 Bcrri, Montréal, Jean Tberien, printer, 7800 Place Seuilly, Anjou, Pierre Vincent, director-manager, 0403.2nd Avenue, Montréal.1.-Gérard Drainvillc, sales director, 6041 des Angevins, Anjou.Bernard (irégoire, public relations director, 10355 Esplanade, Montréal, Guy Crevier, administrator, 760 Rochon, Saint-Laurent.Roger Meunier, broker, 9957 Grande-Allée, Montreal, Jean Goulet advocate, 5759 Déom, Montréal, Raymond-A.Robic, industrial property counsellor, 2100 Driimmond, Montréal, Jacques Bernard, trader, 5255 Rrillon, Montréal, Armand-L.Godin, director, 9005 Christophe-Colomb, Montréal, J.-Rcné Wilhel-my, trader, 306 Barton, Montréal, J.-Rernard Lavigueur.engineer, 74 Maplewood, Montréal, René Paré, advocate, 535 Outremont, Montréal, Lionel Gascon, chartered accountant, 7220 Sagard, Montréal.1.-Albert Charbonneau, promotion secretary.Campagne Fédération du (irand Montréal, Montréal, Michel Rohillard, notary.0230 Châtelain.Montréal, Jean Lacroix, chartered accountant.0930, 9th Avenue, Montréal, Joseph Germain, broker, 532 des Pins West, Montréal.Gérard F'rigon.general director.12212 Beauséjour, Montréal.Pierre Charest, administrator.1664 Manitou.Laval.Treille Boulanger, administrator.3S33 Place Yictor-Bourgcau.Montréal, Fcrnand Messier, industrialist, 70S Wiseman, Outremont, J.-Paul Baritcau.associate general director, 77 St-.Ioseph West.Montréal.Paul Dumas, administra tor, 900 Rockland.Outremont, Lionel-A.Audette, insurance broker.4665 Borden.Montreal, Pierre Gratton, securities broker, 101 Pierre-Davignon, Boucherville, Yvon Hétu, school director.5521 Rélanger, Montréal, and Pierre Lussier, trader, 36 Hollywood, Outre-nioiil.for the following purposes: To carry on charitable activities and in particular to aid infants and youths, under the name of \"Lu Fondation Richelieu Montréal\".The amount to which is limited the immovable property which the corporation mav acquire and possess, is S 1,000,000.The head ollice of the corporation is at Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Dor vii.i.k.Assistant Secretary of the Province.25015 1814-68 Foyer dc Valcourt inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Alphonse-Raymond Bombardier, annuitant, Laurent Dorais, department manager, Roland St-Pierre, engineer, all three of Montcalm Street, Camille Rouillard, doctor-veterinary, 937 Montcalm, Marccllin Bouthiller, department manager, St-.Ioseph Street, Laurent Beaudoin.industrialist, and André Marcoux, doctor, de l'Église Street, all seven of Valcourt, for the following purposes: To furnish aged couples and the aged of both sexes with a home allowing them to live in security and within the atmosphere of a true family spirit, under the name of \"Foyer de Valcourt inc.\". 3336 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 196.9, 100' année, n\" 25 Le montant auquel est limitée la valeur ries biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Valcourt, district judiciaire de Bedford.Ia) sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 1273-68 Garage de l'Est inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour dc mai 1968, constituant en corporation: Robert l'igeon, 11250, Ste-Julic, Montréal-Est, André Villeneuve, 780, Houde, Saint-Lambert, et Jacques Clément, 3508, Marcil, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « Garage dc l'Est inc.», avec un capital total de $10,000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Pointeaux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire dc la vrovinec, Raymond Douville.25015-o 2063-68 The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $500,000.The head oflice of the corporation is al Val-court, judicial district of Bedford.Raymond Douvii.i.i:, Assistant Secretary of the Province.25015 1273-68 Garage de l'Est inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Pigeon, 11250 Stc-Julic, Montreal-East, André Villeneuve, 780 Houde, Saint-Lambert, and Jacques Clément, 3508 Marcil.Mont-real, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as garagc-kcepers and lo deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Garage de l'Est inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Pointeaux-Trembles, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i:, Assistant Secretary of the Province.25015 200348 Garage Tremblay automobiles inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de mai 1908.constituai! en corporation: François Tremblay, garagiste, Sylva Tremblay, tous deux de 500, rue St-ftticnne, «I Raymond-Pierre Tremblay, rue du Congrès, ces deux derniers mécaniciens, tous trois de La Malbaie, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « (iarage Tremblay automobiles inc.avec un capital total de $40.000.divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.I* siège socinl de la compagnie est 500.rue St-Éticnne, La Malbaie, district judiciaire dc Saguenay.Le sous-secrêtaire de la prorince.Raymond Doi vii.i.k.25015-o 1039-G8 Graphic Estates Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc lu province a accordé «les lettres patentes, en date du 25e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Ashcr Kalin.avocat, 484, chemin Duffcrin.Hampstcad.Grace Blac-kett.5622, Sherbrooke.Delphine Matthew, 3455, rue Aylmer, toutes deux de Montréal, et Gladys Matthys, 21, Plateau Normand, Repentigny, ces trois dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de portefeuille, sous le nom dc «Graphie Estates Limited», avec un capital total dc 8200,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et en 18,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Garage Tremblay automobiles inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 9th day of May, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Francois Tremblay, garage-keeper, Sylva Tremblay, both of 500 St-Elienne St., ami Raymond-Pierre Trcmbluy.du Congres St., the two latter mechanics, all three of La Malbaie, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, and lo denl in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"(iarage Tremblay automobiles inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head oflice ol the company is at 500 St-Etienne St., La Malbaie, judicial district of Saguenoy.Raymond Doi vii.i.k.Assistant Secretary of the Province.25015 1939 OS Graphic Estates Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dab he 25th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Asher Kalui, advocate.484 Duffcrin lb*.id.Ifamsntcad.Grace Blackctt, 5622 Sherbrooke, Delphine Matthew.3455 Aylmer Street, both of Montreal, and Gladys Malthys.21 Plateau Normand, Repentigny, the latter three secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Graphic Estates Limited\", with a total capital stock of $200.000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 18,000 preferred shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22.1908, Vol.100, No.25 I.c siege social Je la compagnie est a Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douville.25015 1905-68 Jean Grondin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouvemeur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour dc mai 1968, constituant en corporation: Fernand Lévesque, 3655.rue Papineau, .I.-Émilien Simard, 4055, avenue Madison, tous deux avocats, et Léo Larocque, administrateur, 2890, rue Monsabré, tous trois atentes.en date du lie jour de mai 190S.constituant en corporation: Philip Shaposnick, 6870, Cliester, .Montréal, Gary Moscowitz.2(i(), St-Auhin.Saint-Laurent, et David (ioldcnldatt.71)2ô, Côte Saint-Luc, tous trois avocats.|>our les objets suivants: Agir, en général, à titre dc consultants et conseillers pair toute entreprise commerciale ou organisation industrielle, sous le nom de « lloneyciitt Inc.>.avec un capital total de S4(),(K)0.divisé en 20.000 actions ordinaires de SI chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Ix1 siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Doi vii.i.k.25015 2050-08 Hôpital Général de la Région de l'Amiante inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour d'avril 1908.constituant en corporation sans capital-actions: André Couture, gérant de magasin.450.l'ecteuu.Alphonse Tanguay.mécanicien.21.d'Autcuil.et Kolnnd Picard, industriel.50.Kenneth nord, tous trois de Thetford Mines, pour les objets .suivants: Établir, maintenir, organiser, agrandir, «léve-lopisT cl administrer un hôpital, sous le nom de * Hôpital Général de la Région de l'Amiante inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir el posséder lu corporation, est de SS.000.000.Ix.' siège social tic lu corporation est à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic./.«?xou.i-.sirrétaire de la /irorince.Raymond Douville.25015-o 1202-08 Y.Ilimeaoll Television Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Charles Hrownstcin, 0012.chemin de Nice, Côte Suint-Luc.Ilariich Pollack, et Isidore Grccnhaiim.ces deux derniers de 1255, University, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Fabriquer, réparer, louer «les appareils et accessoires électriques, et en faire le commerce, sous le nom de « Y.Iluneault Television Inc.», avec un capital total «le $40.000.divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune Lesiège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./a .sou.s-.serrétaire de la prorince, Raymond Doiville.25015 1530-08 Icclicrg Refrigeration Inc.Avis est «lonné qu'en vertu de la première partie dc la l«oi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé «les lettres patentes, en date du 3e jour dc mai 1968, cons- Honeycutt Inc.Notice is given that under Purl I of i!\u201e.Companies Act.letters patent, hearing date ||IP 6th day of May.1968.have lieen issued |,v the Lieutenant-Governor of the Province.corporating: Philip Shaposnick, 6870 Che.ter.Montreal.Gary Moscowitz.200 St.Aubin, Saint-Laurent, and David Goldenblatt, 7925 Kingsley.Côte Suiut-Luc, all three attorneys, for the following purposes: To act as consultants and advisers in general to any commercial enterprise or industrial or.gaiiization, under the name ol \"Honeycutl I i.e.\", with a total capital stock of $40.000.divided into 20.000 common shares of SI each ami 20,000 preferred shares of SI each.The head oflice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.R w.MONi) Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015-O 205648 llopii al Général de lu Région de l'Amiante inc.Notice is given that Ululer Part III of t he Companies Act.letters patent, hearing dale the 25th day of April 1908.have Iktii issued by the Licutcnunt-Govcrnor «>f the Province lo incornorato a corporation without share capital: Andre Couture, store manager.450 f'cc- N'au.Alphonse Tanguay, mechanic, 21 d'AuteuQ, and Roland I'icard.industrialist.50 Reniielh North, all three of Thetford Mines, for the following pur|»)ses: To establish, maintain, organize, enlarge, develop and manage a hospital, under the name of \"Hôpital Général de la Région de l'Amiante inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the cor|>oruli»n may acquire and |hisscss.is $$.000.000.The head ollice of the cor|k>rat ion is at Thetford Mines, judicial district of Megalitic.Raymond Doiville.Assistant Seeritary of the Province.25015 1202-08 Y.Iluneault Television Inc.Notice is given that under Pari I of \u2022 be Companies Act.letters patent.Iicaring date the 20th day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Charles Hrownstcin.0012 Nice Road, Côte Saint-Luc.Raruch Pollack, and Isidore Greenbaum.the latter two of 1255 University, Montreal, all three advocates, for Ihc following purposes: To manufacture, repair, lease and otherwise deal in electrical appliances and accessor^ -, under the name of \"Y.Iluneault Television Inc.\", with a total capital stock of 140,000, divided into 1,000 common shares of S10 each unci 300 preferred shares of $100 each.The head oflice of the company is at Montreal, judicial «listrict of Montreal.Raymond Douville.Assistant Secretary of the Prorince.2.5015-o 1530-OS Iceberg Refrigeration Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.June 22.1968, Vol.100, So.25 3339 tituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, Claremont, Westmount, J.Roy Hoffman, 5(515, l'incfulo, Côte Saint-Luc.tous deux avocats et conseillers en Loi de la reine.Oscar Respite, 4945.(ilcncairm, Montréal, et Sydney B.Sede-roffi SO.avenue Crestwood.Montréul-Ouest, ces deux derniers avocats, iwur les objets suivants: l'aire le commerce de machinerie «le réfrigération, tic climatisation, et de glace, et d'équipe-mciil de toute sorte et dc toute description, sous le nom de « Iceberg Refrigeration Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 100 allions ordinaires «le $100 chacune et en 300 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de lu compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-sccrélairc de la province, Raymond Douville.25015 2072-68 Imprimerie Vanier inc.Avis est donné qu'en vertu «le la première partie «le lu Loi des comjmgnics, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentee, en date «lu 26e jour «l'avril 1968, constituant en corporation: Gilles Latulippe, comptable, 6, Cbapais, Itcauport.Marc Robi-taillc.voyageur.424.Cotnoir.Vanier.et Jean-Guy Bonne, mécanicien d'outillage.534, l'ère (¦renier, (Québec, |>our les objets suivants: l'aire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et lithographes, sous le nom «le ¦ Imprimerie Vanier inc.».avec un capital total de $40,000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées dc $luil chai une.Le siège social dc la compagnie est 376.avenue l'roiilx, vanier, district judiciaire «le Québec.Le sous-sccrHaire de la province, Raymond Douville.2Ô015-o 1929-68 Les Industries Gannon t liée Garmont Industries Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi (les compagnies, le lieutenant-gouverneur île la province a accordé îles lettres patentee, en date du 10e jour dc mai 1968, constituant en corporation: Gérard Audet, pl.hier industriel, Pierre Audet, étudiant en génie civil, et Danielle Audet, secrétaire, fille majeure, tous trois «le 2314.Harvard, Montréal, pour les objets suivants: luire affaires comme constructeurs et manufacturer et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom «le « Les Industries Garmont liée \u2014-Garmont Industries Ltd.», avec un capital total «le $50,000, divisé en 50,000 actions de $1 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Maria, district judiciaire «le Bonaventure.Le sous-seerftaire de la province, Raymond Dol'vili.k.25015-o 2116-68 Nelson Jalbert inc.Avis est donné qu'en vertu de la première IKirtic de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentes, en date du 1er jour «le mai 1968, l'instituant en corporation: Nelson Jalbert, commerçant, Thérèse Malicu.ménagère, épouse «\u2022ontraetiicllcnient séparée de biens dudit Nelson Jalbert, tous deux de 50, 21c rue, et Jean Lan- corporating: Max S.Kaufamn, 574 Claremont, Westmount, J.Roy Holfman, 5615 l'incdale.Côte Saint-Luc, both aihwatcs and Queen's Counsels, Oscar Respitz, 4945 Glcncairn, Montréal, and Sydney B.Sederoff, 80 Crestwood Avenue, Montréal West, the latter two advocates, for the following purposes: To deal in refrigeration, air-conditioning and ice making machinery and equipment of every kind and description, under the name of \"Ice-lierg Refrigeration Inc.\", with a total capital stock of $40,000,divi«lc«l into 100 common sliarcs of $100 each and 300 preferred shares of $100each.The head ollice of the company is at Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, .Issislant Secretary of the Province, 25015-o 2072-68 Imprimerie Vanier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 26th day of April.1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: (idles Latulippe, accountant, 6 Chupais, lieaii|k>rt, Marc Rohitaillc, voyageur, 424 Cotnoir.Vanier, and Jean-Guy Rolduc, tool mechanic, 534 Père G renier, Quél-cc, for the following purposes: To carry on business as editors, printers, engravers.I look binders ami lithographers, under the name of \"Imprimerie Vanier inc.\".with a total capital stock of $40.000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 376 Proulx Avenue, Vanier, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1929-68 Les Industries Garmont ltée Garmont Industries Ltd.Notice is given that under Part I of the Comiwnies Act, letters patent, bearing date the 10th day of May.1968.Iiavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gérard Audet, industrial plumlicr, Pierre Audet.civil engineering student, and Danielle Audet, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 2314 Harvard, Montréal, for the following purposes: To carry on business as builders and to manufacture ami deal in all kinds of materials, under the name of \"Les Industries Garmont ltée \u2014 Garmont Industries Ltd.\", with a total capital stock of $50,000.divided into 50,000 sliares of $1 each.The head oflice of the company is at Maria, judicial district of Bonaventure.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2116-68 Nelson Jalbert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of May.1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Nelson Jalbert, trader, Thérèse Maln-ii, housewife, wife contractually separate as to property of the said Nelson Jalbert, both of 50, 21st St., and Jean Langevin, chartered 3340 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 gcvin, comptable agrée, 165, 4e avenue, tous trois eariiig date the 30th day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-.iovernor of the Province, incorporating: Jacques Guerin, 193 BeacOnsfiletl Blvd., Beaconsfield, Bernard Tai Defer, 5505 Marcel-Moiiettc St.Montreal-North, ami Andre Brunei.3505 Lagarde St.Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as garage-koc|)crs, and to operate an automobile rental agency, under the name of \"Lantliicr & Lalondc location limitée Lantliicr & Lalondc Leasing Limited\", with a total capital stock of $52.500.divided into 2.500 dass \"A\" shares of a nominal value of $0.50 each, 22,500 class \"R\" shares of a nominal value of $0.50 each and 2.000 preferred shares of 820 each.The head ollice of the company is at 4391 Papineau St.Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doi;vii.i.k.Assistant Seen/an/ of the Province.25015 1170-08 Lamer Binding Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, hearing dale the 2nd day of May.1908.huve been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Alliert Malouf.advocate and Queen's Counsel, 107 Normandy Drive.Moiiiu Royal.James Galileo.1007 Massenet.Laval, and Michel Taddeo, 0428 Monk Boulevard, Montreal, the latter two advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in binding, tapes, trimmings, narrow fabrics, and wearing apparel generally, under the name of \"Lamer Rinding Inc.\".with a total capital slock of $10.100.divided into 100 common slum's of $1 each and 1,000 preferred shares ol $10 each.The head ollice of the company is at tit) Jean-Talon Stieet West.Montreal, judicial district ol Montreal.Raymond Dor vii.i.k.Assistant Secretary of the I'rorincc.250154 2031-08 France Langelier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters |iatcnt, bearing dale lite 23rd day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-cor|Hirating: Denise Turcotte, 315 St-Iean.Denise I^ichance, 1155 Claire-Fontaine, both of Quebec, and Sii/ette Bilodeau, 24 Wolfe.Levis, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To carry on business as antique dealers, under the name of \"France Langelier inc.\".with a total capital stock of $40.000.divided into 4.000 common shares of a (tar value of $10 each.The head office of the company is at Quebec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1858-6S Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douville.25015-o 1858-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, IOCS, Vol.100, No.25 3343 li.Laprade & fils inc.,V\\i» est donné qu'en vertu «le la première untie 'le la Iration: Rosaire Laprade, commerçant, Marie-Ange Comtois, ménagère, épouse commune en biens dudit Rosaire Laprade, et ilùnii'iil autorisée |>ar lui aux fins des présentes.Ions ileux de 4725.chemin St-Rocli.Tracy, et Biais\" Lincoiirt.comptable.34.Charlotte, Sorel, pOir les objets suivants: Kai.e le commerce de vêtements de toutes siirii -.sous le nom de « R.Laprade & fils inc.», ivec un capital total de 840.000.divisé en 500 ¦étions oïdinairesdeflO chacune et en 350 actions privih giées de 8100 chacune.Le siège social de la coni|iagnic est 4725, chemin St-fioch, Tracy, district judiciaire de Ricin-lieu.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvii.i.i:.2501.m.2068-68 A.Leduc et frères limitée Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant- gouverneur de lu province u accordé des lettres (¦lentes, en date du 0c jour de mai 1068.constituant en corporation : Adrien Leduc, commerçant.Flore-Aimée Lécuyer, ménagère, épouse commune en biens dudit Adrien Leduc, cl dûment iiillni i-ée par lui aux fins des présentes, tous deux île 138, 4e rue.et Raymond Leduc mécanicien, {I, boulevard Pie XII.Ions trois de Saint-Timo-tliée.comté de Rcauliarnois.|Miur les objets suivants: Pure affaires comme compagnie de transport rl exploiter des parcs de stationnement, des Mations de service et des ateliers pour la réparai iun des véhicules automobiles et des moteurs, suis le nom de «A.Leduc et frères limitée», arec un capital total de 140,000, divise- en 2.000 ¦étions ordinaires de 810 cliaeunc et en 2,000 triions privilégiées de 810 chacune.I.i siège social de la compagnie est à Saint-l'ininlliée, district judiciaire de Rcauliarnois.Le sous-secrêtaire île la nmrinee, Raymond DoU ville.80I5-o 2198-68 Leisure Lady Originals Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnaut-piiiverneur dc la province a uccordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai 1908.consti-loam en corporation: Eisa Suykaly, vendeuse, épouse d'Edward Saykaly, 424, Simcoe, Mont-Royal, Ronald Ayoub, 11549.rue Sulk.Montréal-Nord, Leo Aziz.120.Graham, Mont-Royal, tous deux manufacturiers, et Fred Ahdo.vendeur.1249.bougie Saint-Laurent, |K>ur les objets savants: l.i fabrication et le commerce de vêtements et accessoircs vestimentaires de toutes sortes, soils le nom de « Leisure Lady Originals Inc.», avei mi capital total de $150.000.divisé en 15.000 «lions ordinaires de $1 cliaeunc et en 135.000 «'tiens privilégiées de $1 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.R, Laprade & fils inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of May, 1968, liavc lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rosaire I^aprade, trader, Marie-Ange Comtois, housewife, wife common as to property of the said Rosaire Laprade, and duly authorized by him for these presents, lioth of 4725 St-Roch Road.Tracy, and Blaise Lincourt, accountant, 34 Charlotte, Sorel, for the following purposes: To carry on business dealing in all kinds of clothing, under the name of \"R.Laprade & fils inc.\".with a total capital stock of $40,000.divided into 500 common shares of $10 each and 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 4725 St-Roch Road, Tracy, judicial district of Richelieu.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.25015 2068-68 A.Leduc et frères limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 9th day of May.1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adrien Leduc, trader.Florc-Aimée Lécuyer.housewife, wife common as to property of the said Adrien Leduc, and duly authorized by him for these presents, both of 1.18, 4th St.ami Raymond Leduc, mechanic, 51 l'ic XII Blvd., ull three of Suint-Timothéc.county of Beau-harnois.for the following pur|>oses: To carry on business as a transport com|>any, and to operate parking lots, service stations and automobile and motor repair shops, under the name of \"A.Leduc et frères limitée\", with a total capital stock of $40.000.divided into 2.000 common shares of S10 each and 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Timothée, judicial district of Bcauliarnois.Raymond Doi-ville.Assistant Secretary of the Prorince.25015 2198-68 Leisure Lady Originals Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, hearing date the 7th day of May.1908.liavc been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Eisa Saykaly, saleslady, wife of Edward Saykalv.424 Simcoe, Mount Royal, Ronald Ayouh.' 11549 Salk Street.Montreal North.Ix-o Aziz, 120 Graham.Mount Royal, butli manufacturers, and Fred Abdo, salesman, 1249 Bougie, Saint-Laurent, for the following purposes : To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Leisure Lady Originals Inc.\", with a total capital stock of $150.000.divided into 15.000 common sliares of $1 each and 135,000 preferred sliarcs of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Le sous-secrêtaire de la province.Raymond Douville.25015 2125-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015-o 2125-68 3344 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1908, 100' annfe, n° 25 Les Loisirs Duberger inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour dc mai 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques LcMay, 105, Laurier, Québec, Maurice Jacques, 1115, Vimont, et Claude-A.Blanchard, 1187, St-Cyrille ouest, ces deux derniers de Sillc-ry, tous trois avocats, pour les objets suivants: Etablir et exploiter des centres de loisirs, sous le nom de « Les Loisirs Duberger inc.».I.c montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social dc la cor|>oration est 67, boulevard Central nord, Duberger, district judiciaire dc Québec.Lt .sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2147-68 Les Loisirs Duberger inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province lo in\", corporate a cor|>oration without share capital: JaCqUeS LcMay, 105 Laurier, Québec, Mamie,.Jacques, 1115 Vimont, and Claude-A.Blanchard, 1187 St-Cyrillc west, the two latter of Sillcry, alll three advocates, for the following purposes! To establish ami operate recreational centers, under the name of \"Les Loisirs Duberger inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the coriioralion may acquire and hold is to be limited, is $500,000.The head ollice of the corporal inn is at 07 Central Blvd.North, Duberger, judicial district of Québec.Raymond Douvii.i.i , Assistant Secretary of the Prorince.25015 2147-OS Magasin Continental (Shippagan) liée Continental Store (Shippagan) Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la I.oi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'avril 1908, constituant en corporation: Rosario Desbiens, 245, boulevard St-Sacrcment, Lorenzo Brisson, 299, boulevard St-Sacrement, tous deux commerçants, et l'alll-ftmile Normand, comptable, 734, rue Turgcon, tous trois de Chicoutiini, pour les objets suivants: Exploiter des magasins et restaurants, sous le nom de « Magasin Continental (Shippagan) ltée \u2014 Continental Store (Shippagan) Ltd.», avec un capital total de $42.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune, 2,000 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Chicoutiini, district judiciaire dc Chicoutiini.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-0 1410-68 Magasin Continental (Shippagan) ltée Continental Store (Shippagan) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 24th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-corporating: Rosario Desbicns, 245 St.Sacrement Boulevard, Lorenzo Brisson, 299 St.Sacrement Boulevard, both traders, ami Pnul-Eiuile Nor-inniid, accountant, Turgcon Street, all three of Chicoutiini, for the following puriwses: To operate stores and restaurants, under the name of \"Magasin Continental (Shippiieaiu ltée \u2014 < mil menial Store (Shippagan) Ltd.\".with a total capital stock of $42,000, divided into 2,000 common shares of $10 each, 2.000 class \"A\" preferred shares of $10 each ami 2,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head ollice of the company is at Chicoutiini, judicial district of Chicoutiini.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1410-68 La Maison du Peuple de Montréal inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de mai 1908, constituant en corporation : Madeleine Perron, écrivain, épouse de Rolvert Cliche, Paul Enflamme, avocat, et Rita (iagnon, secrétaire, fille majeure, tous trois «le Saiut-Joseph-de-Bcauce, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « La Maison du Peuple dc Montréal inc.», avec un capitl total dc $40.000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Joseph-de-Beaucc, district judiciaire de Beaucc.Le sous-secrêtaire dc la province, Raymond Douville.25015-o 1723-68 Maison Maxime (1968) inc.La Maison du Peuple dc Montréal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of May, 1968.liavc been lamed by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Madeleine Perron, author, wife of Robert Cliche, Paul Laflamme, advocate, and Rita (iagnon, secretary, spinster of the full ace of majority, all three of Saint-Joseph-dc-Bcauce, for the following purposes: To carry on business dealing in furniture 01 I novelties of all kinds, under the name of \"La Maison du Peuple de Montréal inc.\", with ¦ total capital slock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head ollice of the company is at Saiu'-Joseph-dc-Bcaiicc, judicial district of Bcauce.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1723-OS Maison Maxime (1968) inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, have been issued Avis est donné qu'en vertu de la première partii' de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3345 patentes, en date du 7e jour ur les objets suivants: Paire affaires comme épiciers, sous le nom dc ' E.A.Ranger & fils ltée », avec un capital total île $40,000, divisé en 2,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,500 actions privilégiées dc $10 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-secrétaire de la prorince, raymond Douvillk.25015-o 1511-68 Recherches Soiis-Miirincs du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la l.m des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de mai 1968, constituant eu corporation sans capital-actions: Denis Borgeat, industriel.2865, Vahnont.Sainte-Foy.(iérard-A.Verge, ingénieur, 1112.Vimont.et Jean-Louis Doiicet.avocat, 2144, Hoisjoli, ces deux derniers de Sillcry.pour les objets suivait ta: Promouvoir et encourager le sport de la plongée sous-marine, sous le nom de < Recherches Sous-Marines du Québec inc.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que |>eut acquérir et posséder la corporation, est de $.50,000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrêtaire dc la province, Raymond Douville.25015-o 2161-68 Reina Concessions Inc.Concessions Keina inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 1968, constituant en cor|Miration : Philip Shaposnick, 6870, Chester, Montréal, Gary Moscowitz, 260.rue St-Aubin, Saint-Laurent, et David Gohlcnhlatt, 7925, Kingslcy, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Agir, en général, à titre de consultants et conseillers jtoiir toute entreprise commerciale ou organisation industrielle, sous le nom île « Reina Concessions Inc.- Concessions Reina inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées dc $1 chacune.To act as consultants and agents for all enter-prises, under the name of \"Jean Provost et associés, ltée \u2014 Jean Provost & Associates Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,900 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company is at 6000 Me-tropolitain Rlvd., Suite 205, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i:, Assistant Secretan/ of the Province 25015 1868-6!) K.A.Ranger & fiIs ltée Notice is given that under Part I of II.< Companies Act, letters paient, bearing date llie 15th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Emmanuel Aimé Ranger, grocer-butcher, 1955 des Carrières Houlevard, Denis Ranger, 1955A des Carrières Houlevard, and ( iuy Hanger, butcher, 1957 des (\"arrières Houlevard, all Ihrecnf Montreal, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"K.A.Ranger & fils ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.500 common sliarcs of $10 each and 1.500 preferred shares \"1 $10 each.The head oflice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvilli:.Assistant Secretary of the Protiiirt.2.5015 1511-68 Recherches Sous-Marines du Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act.letters patent, tearing date the 10th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a cor|>oratioii without shure capital: Dink Rorgeat, industrialist, 2865 Valmont.Sainte-Foy.Géniril-A.Verge, engineer.1112 Vimont.and Jean-Louis Doiicct, advocate.2144 Hoisjoli.the latter two of Sillcry, for the following purposes: To promote and encourage under-water diving, under the name of \"Recherches Sous-Marines du Québec inc.\".The amount to which is limit ed the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $50,000.The head oflice of the corporation is at Québec judicial district of Québec.Raymond Douvillk, Assistant Secretan/ of the Province.25015 2161-68 Rcina Concessions Inc.Concessions Reina inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing dale the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Philip Shaposnick, 6870 Chester, Montreal, Gary Moscowitz.260 St.Aubin.Saint-Laurent, and David Goldcnblatl, 7925 Kingslcy, Côte Saint-Luc, all three attorneys, for the following purposes: To act as consultants and advisers in general to any commercial enterprise or industrial organization, under the name of \"Reina Concessions Inc.- < 'onccssioiis Reina inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 20.000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, IOCS, Col.100, No.25 8865 |,c siège social de la compagnie est à Montréal, di-trict judiciaire de Montréal.Ia! sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2501£ 2057-68 l.a Rénovation Urbaine «le Montréal inc.A\\ i> est donné «pi'cn vertu dc la première partie la Ia» des compagnies, le liriitciiaut-ffouveroeur «le la province a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de mai l!)(iS, constituant en corporation: Harry L.Aronovitcli, 5023, Randall, Arthur I.Bronstein, 5703.Kldrid-jr\\ tous deux dc (\"(\".te Saint-Luc, et llohert S.Litvack, 590, Stanstead, Mont Royal, tous trois ivocatii pour les ohjeLs suivants: Kxploitor une com|>agnic d'immcuhlcs, dc construction et de placements, sous le nom de «la Rénovation Urbaine de Montréal inc.».avec un capital total de $25.000, divisé- en 500 allions onliuaires d'une valeur au pair de $10 chacune «-t 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair île $10 cliacune.\\r siège social de la compagnie est 3333 route Qurrn Mary, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province.Raymond Douville.25015 1002-08 Restaurant Blotiin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres pit entes, en date du 3e jour de mai 1008, constituant en corporation: Roger Rlouiu.restaurateur.216.St-Vallier ouest, Jacques Taschcreaii.notaire, .315.Laurier, tous deux de Quél>ec, et PaulineCantin, secrétaire, fille majeure, Lorcttc-villc, pour les objets suivants: Exploiter des restaurants, cabarets et cafés, mis le nom de « Restaurant Rlouiii inc.*, avec un capital total de $40.000.divisé en 1.000 actions orilinaires dc $1 cliacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.¦-'5015-o 2026-68 J.L.Roberge & fils amusements inc.\\vis est donné qu'en vertu de la première polie de In Loi des compagnies, le lieutenant-gouvemeur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 1968, constituant eu corporation: Jean-Louis Roberge, commerçant, Lise Laflammc, ménagère, épouse .I ractucllement séparée de biens dudit Jean- I \"lis Rolverge, tous deux de 1105.chemin St-Ours, Saint-rierre-de-Sorel, et Biaise Lincourt, comptable, 34, Charlotte, Sorcl, pour les objets suivants: Kxcrccr le commerce qui consiste à fournir de l'amusement au public, sous le nom de < J.L.Roberge & fils amusements inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions orilinaires de $10 chacune et en 350 actions privilégiées de $100 cliacune.I«e siège social de la compagnie est 1105, chemin St-Ours, Saint-Picrre-ile-Sorel, district judi-1 i.iire de Richelieu.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-u 2069-68 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-0 2057-68 Lu Rénovation l'rbuiiie de Montréal inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Ad, letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1968, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorpira-ting: Harry L.Aronoviteh, 5623 Randall, Arthur I.Bronstein, 5703 Kldridgc.loth of Cote Saint-Luc, and Roliert S.Litvack, 590 Stanstcad, Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"La Rénovation Urbaine de Montréal inc.\".with a total capital stock of ?'_'.\">.(MX), divided into 500 common shares of the par value of $10 each and 2.000 preferred shares of the par value of $10 each.The Inad office of the company is at 3333 Queen Mary Road, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville., Assistant Secretary of the Province.25015-o 1602-68 Restaurant Blouin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters [Mitent, bearing date the 3rd day of May, 1968, have lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor-pirating: Roger Blouin, restaurant keeper, 216 St-Vallier West.Jacques Taschereau, notary, 315 Laurier, l>oth of Québec, and Pauline Cantin, secretary, spinster of the full age of majority, Lorettcvillc.for the following purposes: To iqieratc restaurants, calwrets and cafés, under the name of \"Restaurant Blouin inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1.000 common shares of $1 each and into 390 preferred sliares of $100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2026-68 J.L.Roberge & tils amusements inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Oth day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Louis Roberge, trader, Lise La-flamme, housewife, wife contractually separate as to projierty of said Jean-Louis Roberge, both of 1105 St-Ours Road, Saint-Pierre-de-Sorel, and Blaise Lincourt, accountant, 34 Charlotte, Sorel, for the following purposes: To operate a business consisting in furnishing entertainment to the public, under the name of \"J.L.Roberge & fils amusements inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 350 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1105 St-Ours Road, Saint-Pierre-dc-Sorcl, judicial district of Richelieu.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2069-68 3350 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin lOCft, 100' année, n° 25 Rosemère House Inc.La Maison Rosemère inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Alphonse Barbeau, 847, Dunlop.Outremont, Antoine Paré, 1115 ouest, rue Sherbrooke, tous deux avocats, et Charlotte Roux, réceptionniste, célibataire, 3281, Forest Hill, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Fournir des services de toutes sortes aux hôpitaux, aux hôtels, aux maisons pour convalescents, aux maisons pour vieillards et aux autres institutions, sous le nom de « Rosemère House Inc.\u2014 La Maison Rosemère inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-secrHairc de la province, Raymond D ou ville.25015 1771-68 Ross Converters Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour d'avril 1968, constituant en corporation: John Michelin, 5754, Lockwood, Dollard-des-Ornieaux, Jason Ruby, 47, Place Du Rois, Hampstead, et Louis Orens-tein, 5654, MacDonahl, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer toutes sortes de tissus, matériels et accessoires, en faire le commerce et la transformation, sous le nom de « Ross Converters Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 90 actions ordinaires de $10 chacune et en 391 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 24 ouest avenue Mont-Royul, Montréal, district judiciaire de Montréal.Ia sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 1961-68 Georges E.Roy Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie «le la I/>i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai 1908, constituant en corporation: Georges E.Roy, pharmacien, Jacqueline Roy, ménagère, é|xmse séparée de biens dudit Georges E.Roy, tous deux du 1180, Rideau, et Bernard Dussault comptable, 1155, Rideau, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Fabriquer et vendre dans le gros des spécialités médicales, des préparations pharmaceutiques et médicales de toutes sortes, sous le nom de « Georges E.Roy Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions orilinaires de $1 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 102, Sainte-Anne, Saintc-Aiinc-dc-Belleviic, district judiciaire de Montréal.Rose mere House Inc.La Maison Roseini-rc inc.Xoticc is given that under Part I of the Companies Act letters patent, bearing date the 30lh day of April, 1968, have been issued by the Lieutcnant-.iovcrnor of the Province, incorporating: Alphonse Barbeau, 847 Dunlop.Outre-mont, Antoine Pan1, 1115 Sherbrooke Street West both lawyers, and Charlotte Roux, receptionist, spinster, 3281 Forest Hill, the latter two of Montreal, for the following purposes: To provide hospitals, hotels, convalescent and nursery homes and other institutions with servi-ces and facilities, under the name of \"Rosemère House Inc.\u2014 La Maison Rosemère inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25015-o 1771-08 Ross Converters Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John Michelin, 5754 Lockwood, Dollnrd-des-Onncaux, Jason Ruby, 47 Place Du Rois, I lamp-lead, and I.nuis Orcnstcin, 5654 MacDo-nald, Côte Saint-Luc, all three attorneys, for the following purpose-: To manufacture and deal in all types of fabrics, material and apparel and to act as converters, under the name of \"Ross Converters Ltd.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 90 common shares of $10 each and 391 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 24 Mount Royal Avenue West, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 1961-08 Georges E.Roy Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, liave l>ccii issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges E.Roy, pharmacist, Jacqueline Roy, housewife, wife separate as to property of the said Georges E.Roy, both of 1180 Rideau, and Rcrnard Dussault, bookkeeper, 1155 Rideau, all three of Laval, for the following purposes: To make and sell wholesale medical specialties, pharmaceutical and medical preparations of all forms, under the name of \"Georges E.Roy Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head oflice of the company is at 102 Stc-Anne, Sainte-Aiino-ile-BcIleviie, judicial district of Montreal.Le sous-secrêtaire dc la province, Raymond Douville.25015 2095-68 Raymond Douville.Assistant Secretary of the Province.25015^) 2095-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1908, Vol.100, No.2b 3357 SLF Holdings Limited Gestion SLF limitée Avis est donné qu'en vertu dc la premiere partir de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour dc mai 1968, cons-li!u.iut en corporation: Jolui Henry Ernest Colby, Michael Edgar Rioux, Thomas Ross Anthony Malcolm, Paul Michael Deniers, John Arthur Alexander Swift, Duncan Ives McNeill, tous les six avocats, Galen Lee Prime, gérant, lise Nicole Romanelli, et Susan Mary Duchesne, ces deux dernières secrétaires, célibataires, tous les neuf du 1155 ouest, boulevard Dorchester, mite 3301, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de |»rtefeuille, sous le nom de «SLF Holdings Limited\u2014Gestion SI.F limitée », avec un capital divisé en 2,000 allions ordinaires sans valeur au pair et en 3,900 ¦étions privilégiées d'une valeur au pair dc $1,000 chacune Le siège social de la coni|>nguic est à Saluberry-de -Valleyfield, district judiciaire de Bcauharnois.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 1688-68 St-Laurent électrique limit.V Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutcnant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de mai 1968, constituant en corporation: Roger Cyr, journalier, Albert St-Laurent gérant, et Louise Mill, secrétaire, fille majeure, tous trois dc Carlcton, pour les objets suivants: l'aire le commerce d'entrepreneur électricien, de la construction générale, de la réparation et dc la vente des appareils électriques de toutes sortes, sous le nom dc « St-Laurent électrique limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Carlcton, district judiciaire de Bonaventure.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 2165-68 Stan Saibil Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de mai 1968, constituant en corporation: Stan Saibil, étudiant Nancy Saibil, secrétaire, célibataire, et Ben Saibil, administrateur, tous trois du 4700, avenue Kent Montréal, pour les objets suivants: 1 ¦ inner et soutenir une compagnie de théâtre, sous le nom de « Stan Saibil Associates Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 act ions ordinaires de $10 cliacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 4824, chemin de la Côte des Neiges, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 2178-68 Sample Blouse & S port wear Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de mai 1968, cons- SLF Holdings Limited Gestion SLF limitée Notice is given tliat under Part I of the Companies Act letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John Henry Ernest Colby, Michael Edgar Rioux, Thomas Ross Anthony.Malcolm, Paul Michael Dcmers, John ^Arthur Alexander Swift, Duncan Ives McNeill, all six advocates, Galen Lcc Prime, manager, Lise Nicole Romanelli, and Susan Mary Duchesne, the latter two secretaries, spinsters, all nine of 1155 Dorchester Boulevard West, Suite 3301, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"SLF Holdings Limited ¦\u2014 Gestion SLF limitée\", with a capital stock divided into 2,000 common shares without par value and 3,900 preferred shares of the par value of $1.000 each.The bead oflice of the company is at Salabcrry-de-Valleyfield, judicial district of Bcauharnois.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015^0 1688-68 St-Laurent électrique limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger Cyr, labourer, Albert St-Laurent, manager, and Ix>uisc Mill, secretary, spinster of the full age of majority, all three of Carleton, for the following purposes: To carry on business as electrical contractors, and to deal in general construction, repairs and the sale of electrical app'iances of all kinds, under the name of \"St-Laurent électrique limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head ollice of the company is at Carleton, judicial district of Bonaventure.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2165-68 Stan Saibil Associates Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent bearing date the 13th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Stan Saibil, student, Mancy Saibil, secretary, spinster, and Ben Saibil, executive, all three of 4700 Kent Avenue, Montreal, for the following purposes: To form and maintain a theatrical company under the name of \"Stan Saibil Associates Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into, 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 4824 Côte des Neiges Road, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 2178-68 Sample Blouse & Sport « ear Ltd.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor- GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.22 juin 1968.100' année, n\" 2ô hliianl ni corporation: Sain Aclcl, confection-iieur, 470.Plamoudon, Harry Wugiiller, expé-iliii m et Nettie Wiigalter.ménagère épuise diiilit Harry Wugaltcr, ces deux derniers dc 3777, De La Pcltric, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Confectionner des vêtements et articles vestimentaires, en faire le commerce, sons le nom de « Sample Blouse & S|iorlweur Ltd.», avec un capital Mal de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 cliaeunc.Le siège social de la compagnie est 5369, l-oulevard St-Laurcnt, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douvillk.25016 2216-08 Paul Savoie inc.Avis est donné qu'en vertu de la première iwrtie de la I.oi des comiMignics, le lieutenant-gouverneur tie la province u accordé des lettres patentes, en date du 2c jour tic mai 1968.constituant en corporation: Réjane Beuuclicinin, secrétaire, é|X)iise convcntioniicllcmcnt séparée de biens tie Francois Gervais, Lac Lcmoine, Marcelle Perron, secrétaire, épouse conveu-tionnellement séparée de biens de Blake Kelly.117, 7e rue, Bourlamuque, et Andrée l'hilbert.secrétaire, fille majeure, 1020, Bérard, Val d'Or, |K>ur les objets suivants: Industrie et commerce du bois, sous le nom de « Paul Savoie inc.», avec un capital total tie $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Val d'Or, district judiciaire d'Ahitibi.Le sous-secrêtaire dc la province, Raymond Douville.25015-o 1978-08 pirating: Sam Atlcl, manufacturer, 470 l'Ia inondon.Harry Wugaltcr.shipper, and Nettie Wugaltcr.housewife, wife of the said llarrv Wngalter.the latter two of 3777 De La IVHrir, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing ami wear-ing apparel of all kinds, under the name of \"Sample Blouse & Spirtwear Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 com.mon sliaresof $10 each ami 2.000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 5369 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douvii.i.i .Assistant Secretary of the Procinn .250I5-o 221648 Paul Savoie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of May 1008, have been issuctl by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Réjane Beauchemin, secretary, wife conventionally separate as to pro|>erty of François Gervais, Lcmoine Lake Marcelle Perron, secretary, wife conventionally separate as to property of Blake Kelly.117,\" 7th Street.Hour-lamaquc.and Andrée l'hilbert, secretarv, spinster of the full age of majority, 1020 Bérard, Val d'Or, fur the following purposes: The lumlier trade, under the name of \"Paul Savoie inc.\", with a total capital stock of 140,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head oflice of the company is at Val d'Or, judicial district of Abitibi.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prot'inir.25015 1978458 Scandinavian Craft & Decor Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur île la province u accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de mai 1008.constituant en corporation: Hugues Ferron, 2450, avenue Athlone, Mont Royal.Raymond Lc-Imeuf.0280.Northcrest.Montréal, tous deux avocats, et Marcel Dagenais.commis, 237, rue Hector, Rose mere, pair les objets suivants: Faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Scandinavian Craft & Decor Inc.», avec un capital total île 640,000, divisé en 2.000 actions ordinaires île $10 chacune et en 2.000 actions privilégiées de $10 chacune Le siège social de la compagnie est à Pierre-fonds, district judiciaire de Montréal.I.c sous-secrê-taire de la prorince.Raymond Douvillk.250154 2074-68 Sept-Iles métal ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix)i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de mui 1908, constituant en corporation: Jacques Gossclin.regrattier.Thérèse l-al>elle.ménagère, épuise contractuel lenient séparée de biens dudit Jacques Gosselin, tous deux île 834.Brocliu.et Paul Noël, comptable.690.Cartier, tous trois tie Sept-Iles.pour les objets suivants: Scandinavian Craft & Decor Inc.Notice is given tliat initier Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 3rd day of May.1968.have been issuctl by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Hugues Perron.2450 Athlone Avenue, Mount Royal.Raymond Lcltocuf, 6280 Northcrest.Montréal, both advocates, ami Martel Dagenais, clerk, 237 Hector Street.Rosemère.for the following purposes: To ileal in furniture ami novelties of all kinds.Ululer the name of \"Scandinavian Craft «V Decor Inc.\", with a total capital stock of $40,009, divided into 2.000 common sliares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Picriv-fouds, judicial tlistriet of Montréal.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Prorince.25015 2074 us Sept-1 les métal ltée Notice is given tliat under Part I of the Companies Act.letters patent, lwaring date the 10th day of May.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Gossclin.huckster, Thérèse Lalxdle, housewife, wife contractually separate as to property of the saitl Jacques Gossclin, lioth of 834 Brocliu, ami Paul Noël, accountant, 696 Cartier, all three of Sept-Iles, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, June 22, 19GS, Vol.100, No.25 faite le commerce dé métaux dc toutes sortes, leurs produits et leurs sous-produits, sous le iKiin de Sept-Iles métal ltée , avec un capital Mal île $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 cliacune et en 200 actions privilégiées de ||Q0 chacune.^ L, siège smial de la compagnie est 834, avenue Itrm-liii.Sept-Iles, district judiciaire de Hauterive.Le mus-sécréta ire de lu province, Rathonu Douville.B015o 1555-08 Les Services Canafl* ltée Canaff Services Ltd.Avis est donné qu'en vertu do la première partie de lu Loi des compagnies, le licutemint-¦MVerneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai 1908, constituant eu corporation: Richard Gar eau, avocat, 2253, llciijamin-Sultc, Madeleine Tessier-Lavi-¦e, secrétaire, céliliataire, 1016, rue Saint-IIiiIh il.et Liette M.Parent, secretaire, épouse léparéc dc biens de J.-J.Parent, 2449, avenue Iteiiny, tous trois de Montréal, jiour les objets suivants: Exploiter un restaurant, sous le nom de « Les Services ( .m,ill ltée - -Canafl Services Ltd.\", ave- un capital total de $40.000, divisé en 1.000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune et en 3,900 aidions privilégiées d'une valeur au pair de $10 cliacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 2043-68 Les Services St-Lin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la !x>i des compagnies, le lieutcuant-goiivc riicur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour «le mai 1968, constituant en corporation: Thérèse Lavallée, ménagère tille majeure, Pierre-Paul Lavalléo, journalier, tous deux de Saint-Lin, et Louise Label b-, secrétaire, fille majeure, 286, Lebeau, Saint Jérôme, pour les objets suivants: Exercer le commerce d'entrepreneur général, ¦ms le nom de « Les Services St-Lin inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 cliacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.I.c -iège social dc la compagnie est à Saint-l.iu.district judiciaire de Joliette.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2S0I5-O 1342-68 G.Smith Sales Limited Av i- est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Henry Steinberg, Ivocat, 360, ouest, rue St-Jacques, Janice Johnston, 0925, avenue Outremont, et Laura Cobb, 2400.Benny Crescent, ces deux dernières secrétaires, célibataires, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter le commerce dc gros et détail d'un ¦egasin à rayons, sous le nom de «G.Smith Sales Limited », avec un capital total dc $40,000, To carry oil business dealing in all kinds of metals, their products and by-products, under the name of \"Sept-Iles métal ltée\", with a total capital stock of $40.000.divided into 2.000 common shares of $10 each uml 200 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 834 brocliu Ave.Sept-Iles, judicial district ol Hauterive.Raymond Douvillk, Assistant Secretan/ of the Province.25015 1555-08 Les Services Canaff ltée Canaff Services Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, lieuring date the 7th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ricliard Garcau, advocate, 2255 Benjamin-Suite, Madeleine Tessier-Lavigne, secretary, spinster, 1616 St.Hubert Street, ami Liette M.Parent, secretary, wife separate as to property of J.-J.Parent, 2449 Benny Avenue, all three of Montreal, for the following pur|ioses: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Les Services Canafl ltée- Canaff Services Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shures of the par value of $1 each and 3,900 preferred shures of the par value of $10 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.250154 2043-68 Les Services St-Lin inc.Notice is given that under Part I of the ( 'ouipanics Act, letters paient, bearing date the 3rd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, iin m pirating.Thérèse Lavallée, housewife, spinster of the full age of majority, Pierre-Paul Lavallée, labourer, both of Saint-Lin, and Louise Laliellc, secretary, spinster of the full age of majority, 286 Leloeau, Saint-Jérôme, for the following purposes: To carry on business as general contractors, under the name of \"Les Services St-Lin inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head ofKce of the company is at Saint-Lin, judicial district of Joliette.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1342-68 G.Smith Sales Limited Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of April.1968, liavc lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, Li-corporating: Henry Steinberg, advocate, 360 St.James Street West, Janice Johnston.6925 Outremont Avenue, and Laura Cobb, 2400 Benny Crescent, the latter two secretaries, spinsters, all three of Montréal, for the following purposes: To carry on the business of a wholesale, retail anil departmental store, under the name of \"G.Smith Sales Limited \".with a total capital stock 3360 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 19GS, 100' année, n\" 26 divisé on 100 actions ordinaires d'une valeur nu pair île S100 chacune el 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-secrêtaire Je la province, Raymond Dor vii.i.k.25016 1002-08 Sociaad Inc.Avis est donné liu'en vertu de la première partie île la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accorde des lettres patentes, en date du 1er jour d'avril 1008.autorisant la fusion de la compagnie « Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.».constituée en corporation par lettres patentes, en date du 19e jour de mai 1045.dc la compagnie « Triumph Sales Limited ».constituée en corporation par lettres patentes, en date du 12e jour do novembre 1902.et de la compagnie « Triumph Continental Products Limited», constituée en corporation pur lettres patentes, en date du 14e jour de juillet 1959, toutes cesdites let très patentes ayant été émises en vertu dc ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de « Sociaad Inc.», avec un capital-actions, divisé en 11.510 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 250 (7%) actions privilégiées, remboursables non cumulatives d'une valeur au pair de $100 chacune Le siège social de la compagnie est.à Montreal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvillk.25015 1138-08 1118 72 of $40.000, divided into 100 common shares of the par value of $100 each and 300 preferred sbarcs of I be par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Doi;villi, Assistant Secretary of the Province, 25015-o 1962-68 Sociaad Inc.Notice is hereby given that under Pari I of the Companies Act.letters patent bearing dale the 1st day of April.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, authorizing the amalgamation of \"Triumph Industrial and Marine Equipment Ltd.\".in-corporated by letters patent dated the I9tlt day of May, 1945.\"Triumph Sales Limited'.in\", corporated by letters patent dated the 12lli day of November, 1902.and \"Triumph Continental Products Limited\", incorporated by letters patent dated the 14th day of July.1959.all suck letters patent having been issued under the -aid Part I of the Companies Act, for the following purposes: To carry on the business of an in vest nient company, under the name of \"Sociaad Inc.\".with a capital stock divided into 11.510 common shares without nominal or par value and 250 (7%) non-cumulative redeemable preferred shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretan/ of tlie Province, 25015-0 1138-G8 \u20141418/72 La Société Lyrique d'Aubigny, inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 1968, constituant en corporation sans capital-actions: Léan-dre Lapicrrc, vendeur, 704, Commerciale, Saint-David-de-L'Auberivière, Jean-Pierre Audet, professeur, 851, Madeleine dc Verchères, et Guy Bélanger, étudiant, 915, Eyraard, ces deux derniers de Québec, pour les objets suivants: Grouper des personnes intéressées à la musique chorale et promouvoir leur capacité et leur connaissance dans ce domaine, sous le nom de « La Société Lyrique d'Aubigny, inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000.Le siège social de la corporation est 704, rue Commerciale, Saint-David-de-l'Auberivière, district judiciaire de Québec.Le sous-secrêtaire dc la province, Raymond Douvii.i.i:.25015-o 2015-68 Stéréo Laval inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'avril 1968, constituant en corporation: Michel Dagenais, avocat, 383, chemin Ste-Catherine, Outremont, Roland Saucier, radiodiffuseur publicitaire, 1640, Dauphin, Laval, et Ange-Marie Boivin, secrétaire, fille majeure et usant de ses droits, 6460, Ernest-Lavigne, Montréal, pour les objets suivants: La Société Lyrique d'Aubigny, inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1968, nave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incor|)orate a cor|>oration without share capital: Lcandre Lapierrc, salesman, 704 Commerciale, Saint-David-de-1'Auberivière, lean-Pierre Audet, professor, 851 Madeleine de Ver-chères, and Guy Bélanger, student, 915 Eymard, the two latter of Québec, for the following purposes: To group together the persons interested in choral music, and to promote their capacity and knowledge in this field: under the name of \"la Société Lyrique d'Aubigny, inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $10,000.The head ollice of the corporation is at 704 Commerciale St., Saint-David-de-1'Auberivière, judicial district of Québec.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25015 2013-6S Stéréo Laval inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Dagenais, advocate, 383 Ste-Catherine Road, Outremont, Roland Saucier, publicity broadcaster, 1640 Dauphin, Laval, and Ange-Maric Boivin, secretary, spinster of the full age of majority using her rights, 6460 Erncst-Lavigne, Montreal, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22.1908, Vol.100.No.25 3361 Exploiter dos postes émetteurs et récepteurs de radiodiffusion et dc T.S.F., sous le nom dc « Stéréo Laval inc.», avec un capital total de $130,1X10, divisé en 10,000 actions ordinaires de SU) cliacune et en 500 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1, Place Laval, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrétaire Je la province, Raymond Dorvn.i.k.230I5-o 1930-68 Sumac Construction Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutenaut-goiivcrneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de mai 1968, constituant en corporation: Richard S.(îottlicli, 7519.chemin Bailey, Arthur Marcovitch.5525, avenue Trent, tous deux avocats, et Elizabeth Serrao, secrétaire, célibataire, 11777, Dc Mculles, tous trois dc Montréal, pour les objets suivants: Agir à titre de constructeurs et entrepreneurs généraux, sous le nom de « Sumar Construction Ltd., avec un capital total de $10,000.divisé en 1.000 actions ordinaires de $1 chacune et en 39.000 actions privilégiées de $1 chacune.Le >iège social de la compagnie est 3210, Porcs! Ilill, app.1408, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 2032-68 Tradition House Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de mai 1068, constituant en corporation sans capital-actions: Louis (ïlnzer, avocat et conseil en Loi de la reine.876, avenue Dollard, Outremont, Zalmen (iiinvvicz, marchand, 6585 rue Jcanne-Mance, Dr Joseph Slavin, prineipil, 5521, place Bradford.Ben Deutsch, agent, 4210.avenue McKenzic, Cecil A.Labow, manufacturier.5718, Wildwood, Ben Yudclson, agent, 4875, Bourret, tous les cini| de Montréal, Joe Kramer, agent d'immeu-hlcs.771, avenue Powell.Ted Goldberg, directeur, 789, Johnson, tous deux de Mont Royal, Oscar Costin.marcliand, 535.Dorais, Saint-Linrcnt.et Ted Baker, marchand, 6 ', Manuel Drive.DoIlard-dcs-Ormeaux, pour les objets suivants: Stimuler et encourager l'observance du judaïsme traditionnel au moyen d'assemblées culturelles cl en fournissant à ses membres des provisions 'le Kosher Food », sous le nom dc « Tradition House ».Le montant nuquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder ou détenir est dc $.1.000.000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 1959-68 The Trojan Holding Co.Ltd.La Cic de gestion Trojan ltée To operate broadcasting and wireless transmitting and receiving stations, under the name of \"Stéréo Laval inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at I Place Laval, Laval, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1936-68 Su mar Construction Ltd.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters pi tent, bearing date the 2nd day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Richard S.Gottlieb, 7519 Bailey Road, Arthur Marcovitch, 5525 Trent Avenue, both advocates, and Elizabeth Serrao, secretary, spinster, 11777 De Mculles, all three of Montréal, for the following purposes: To carry on business as general contractors and builders, under the name of \"Sumar Construction Ltd.\", with n total capital stock of $40.000.divided into 1.000 common shares of $1 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head oflice of the company is at 3110 Forest Ilill, Apt.1408, Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015^0 2032-68 Tradition House Notice is given tluit under Part III of the Companies Act, letters pilent, bearing date the 6th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: I.oui- Glacer, advocate and Queen's Counsel, 876 Dollard Avenue Outremont, Zalmcn Gu-rewicz, merchant, 6585 Jeannc-Mancc Street, Dr.Joseph Slavin, princqial, 5521 Bradford Place, Ben Deutsch, agent, 4210 McKenzic Avenue, Cecil A.Lnloow, manufacturer, 5718 Wildwood, Ben Viidelson, agent, 4875 Bourret, all five of Montréal, Joe Kramer, realtor, 771 Powell Avenue, Ted Goldberg, director, 789 Johnson, both of Mount Royal, Oscar Costin, merchant, 535 Dorais, S.uni Laurent, and Ted Baker, mercluint, 69 Manuel Drive, Dollard-des-Ormcaux, for the following purposes: To promote and encourage the observance of traditional Judaism by arranging cultural meetings and providing Kosher Food for its members, under the name of \"Tradition House\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $1,000,000.The head oflice of the corporation is at Mon-real, judicial district of Montréal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015-o 1959-68 The Trojan Holding Co.Ltd.La Cic de gestion Trojan ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of May, 1968, have been issued by the Avis est donné qu'en vertu de la première put ie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres 3362 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 patentes, en date du 9e jour de mai 1968, constituant en corporation: John F.Hughes, 48, 10e avenue, Brian F.McKeown, 32, 9c avenue, tous deux de Roxboro, et Jacques Boulianne, 4690, Cavendish, Montréal, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de portefeuille et de placements, sous le nom de « The Trojan Holding Co.Ltd.\u2014 La Cie de gestion Trojan ltée», avec un capital total de S100.000, divisé en 40,000 actions ordinaires de SI chacune et 6,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 69, rue Westminster, Montréal-ouest, district judiciaire dc Montréal.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.25015 195-68 Union Marking Devices Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de mai 1968, constituant en corporation: Edward IL Grand, vendeur, Mildred Lazarus, ménagère, épouse séparée dc biens dc Samuel (irand, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, tous deux dc 1911, avenue MaeDonabl, Carl IL Lew, vendeur, et Ida Lamishoff, ménagère, é|>ouse séparée dc biens de Ilyinic Lew, et dûment autorisée par lui aux fins des présentes, ces deux derniers de 5264, rue Saranac, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter tous ou aucun des commerces d'imprimeurs, libraires, estampeurs, lithographes, éditeurs et agents dc publicité, sous le nom de « Union Marking Devices Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 600 actions ordinaires dc $50 chacune et 200 actions privilégiées de $50 chacune.Le siège social de la compagnie est 4941, avenue MaeDonabl, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-sccrctairc dc la province, Raymond Douvillk.25015 2179-68 Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: John F.Hughes, 48, 10th Avenue, llrian F.McKeown, 32, 9th Avenue, both of Roxboro, and Jacques Bouliannc, 4690 Cavendish, Montréal, all three businessmen, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"The Trojan Holding Co.Ltd.\u2014 La Cie de gestion Trojan ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 40,000 common shares of $1 each and 6,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at 69 Westminster Street, Montréal West, judicial di-trict of Montréal.Raymond Douvillk, .tssistant Secretary of the Province.25015-o 195-68 Union Marking Devices Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor|x>-rnting: Edward II.(irand, salesman, Mildred Lazarus, housewife, wife separate as to properly of Samuel Grand, ami duly authorized by him for the purpose of these presents, both of 4941 MacDonald Avenue, Carl II.Lew, salesman, and Ida l.ami-botf.housewife, wife separate as to property of Hymic Lew, and duly authorized by him for the purpose of these presents, the latter two of 5264 Saranac Street, all four of Montréal, for the following purposes: To carry on all or any of the business\" - of printers, stationers, marking devices, lithographers, publishers and advertising agents, under the name of \"Union Marking Devices Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 600 common shares of $50 each and 200 preferred shares of $50 each.The head ollice of the company is at I'll MacDonald Avenue, Montreal, judicial district of Montréal.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.25015-o 2179-6S Universal Auto Tire V.ST.P.Inc.Universal Auto Tire V.ST.P.Inc.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en dale du 22c jour de mars 1908, constituant en corporation: Pierre Moreau, commis.Ginette Dorais, ménagère épouse con-tracliiellenicnt.séparée de biens dudit Pierre Moreau, tous deux de 35.Eastern Place, app.5, et AIIhtI Dorais, journalier.17.rue Du Moulin, tous trois de Saint-Pierre, pour les bojets suivants: Exploiter «les garages et faire le commerce de pneus d'automobiles, sous le nom de « Universal Auto Tire V.ST .P.Inc.\\ avec un capital total «le $40.000.divisé en 2.000 actions orilinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune Le siège social «le la compagnie est à Saint-Pierre, district judiciuirc de Montréal.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 22nd day of March, 1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Pierre Moreau, clerk, Ginette Dorais, housewife, wife contractually separate as to property of said Pierre Moreau, both of 35 Eastern Place, Apt.5, and Albert Dorais, workman, 17 Du Moulin Street, all three ol St-Pierre.for the following purjwses: To operate garages and to deal in automobile tires, under the name of \"Universal Auto Tire V .ST.P.Inc.\".with a total capital stock ol $40.000.divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The bead oflice of the company is at St-Pierre, judicial district of Montreal.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Douville.25015-o 1205-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1205-68 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3363 Villa Gagnon inc.Avi- est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le licutenant-mverneur de la province a accordé des lettres pi tentes, en date du 29c jor d'avril 1968.cons-liliinnl en corporation: Claude Gagnon, restait-râleur.1264, d'Vouville, Itoland (ingnon, électricien.1196, Fortin, et Jean-Guy Dodier, pliar-mai-icn.254.Onellet ouest, tous trois de Thetford Une*, pont les objets suivants: Exploiter des hotels, tavernes, nuhcrgcs, restaurants el maisons de chamhres.sous le nom île iVilb (iagnon inc.», avec un capital total de 140,000, divisé en 3.50 actions ordinaires de $100 rluuune et en 50 actions privilégiées de S10O cliacune.Le liège social de la compagnie est à Thetford Mine-, district judiciaire de Mégantic.Le sous-secrêtaire de la prorince.Raymond Douville.2S015-O 1950-68 Vitrerie du lias du Fleuve inc.Lower Hiver Glass Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première parlie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour d'avril 1968, «instituant en corporation: Roland Roberge, représentant, 197, Viau, Chicoulimi-Nord, Hriino Bernard, avocat, 147, des Chênes ouest, Québec, il Monique Juneau, secrétaire, fille majeure.62, Durhutcl, Bcauport, pmr les objets suivants: l'aire le commerce de vitrerie, du verre et de l\"ii- -es produits et sous-produits, sous le nom de «Vitrerie du Has du Fleuve inc.\u2014 Lower River Ghaa Inc.», avec un capital total «le §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3.000 actions privilégiées «le $10 chacune.I.e siège social «le la compagnie est à Rimouski, dislric I judiciaire dc Rimouski.Le sous-secrêtaire de la produce, Raymond Douville.250I5-o 2052-68 Villa Gagnon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 20th day of April.1968.have lieon issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-corporating: Claude Gagnon, restaurateur, 1264 d'Youvillc.Roland Gagnon.electrician.1196 Fortin, and Jean-Guy Dodicr, pharmacist.254 Ouellct West, all three of Thetford Mines, for the following purposes: To op-rate hotels, taverns, inns, restaurants and rooming houses, under the name of \"Villa (iagnon inc.\".with a tidal capital stock of $40,000, divided into 350 common shares of $100 each and 50 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Raymond Doiville, Assistant Secretary of the I'rorinre.25015 1956-68 Vitrerie du Has du Fleuve inc.Lower River Glass Inc.Notice is given tluit under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 30th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roland Roberge, representative, 107 Viau.Chicoutimi-Nord, Hruno Bernard, advocate, 147 «les Chênes West, Québec, anil Monique Juneau, secretary, spinster of the full age of majority, 62 Ducluitcl, Beauport, for the following pur|K>ses: To deal in gluziery.glass and all its products and by-products, under the name of \"Vitrerie «lu Bas du Fleuve inc.\u2014 Lower River Glass Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 1,000 common sliarcs of $10 each and into 3,000 preferrcil shares of $10 each.The head ollice of the company is at Rimouski, judicial district of Rimouski.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 2052-68 Volco Hunting and Fishing Club Inc.Club de Chasse et Pêche Volco inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie «le la Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de mai 1968, constipant en corporation: Roger Ferguson, pilote, 594.avenue Gamache, Harry Bamberick, mécanicien, 119, rue Smith, tous deux de Sept-Iles, John .1.Vollman, industriel.190, est rue Principale, Madawaska, Maine, E.U.A., et Robert C.Kce, avocat, 58, chemin Canada, Edmondton, province du Nouveau-Brunswick, pour les objets suivants: Acheter ou acquérir de toute fa«^>n, des baux, concessions ou droits de pêche et «le chasse, sous le nom de « Volco Hunting and Fishing Club Inc.\u2014Club de Citasse et Pèche Volco inc.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 1,000 actions de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 119, rue Smith, Sepl-Bes, district judiciaire de Hauterive.Volco Hunting and Fishing Club Inc.Club dc Chasse et Pêche Volco inc.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of May, 1968, liave been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger Ferguson, pilot, 594 Gamache Avenue, Harry Bamberick, mechanic, 119 Smith Street, both of Scpt-Iles, John J.Voll-mann, industrialist 190East Main Street Madawaska, Maine, U.S.A., and Robert C.Rice, lawyer, 58 Canada Road, Edmunston, province of New Brunswick, for the following purpo.es: To apply for purchase or otherwise acquire any lease, licences, concessions or any fishing and hunting rights, under the name of \"Volco Hunting and Fishing Club Inc.\u2014 Club de Chasse et Pêche Volco inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 shares of $100 each.The head oflice of the company is at 119 Smith Street, Sept-Iles, judicial district of Hauterive.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 1548-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Produce.25015-o _\u2022 1548-68 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1068, 100' année, n\" 25 World Wide Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie île la Loi îles compagnies, le lieutcnant-gouvcriicur île la province a accordé des lettres patentee, co date du 7e jour de mai 1908.constituant eu cor|Mirutioii: Seymour Machloviteh, 3406, Mountain.Montréul.Marvin Hoscnhck.335.Grenïcll.Mont Royal, tous deux avocats, et Madeleine Jack-on.secrétaire, épouse séparée de Liens de Nelson Jackson.575.Laurentien.Saint-Laurent.|Hiur les objets suivants: Exercer le commerce général d'agents, propriétaires, constructeurs, exploitants et gérants de théâtres sous le nom de « World Wide Associates Inc.\u2022-.avec un capital total de 140,000, divisé en 10.IHK1 act ions ordinaires de $1 chacune et 30.000 actions privilégiées de SI cliacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le xoux-secrrlairr de la prorince, R.wmomi Dili'vii.i.k.26016 2021-US Wrcnbury Holdings Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de mai l'.lliS.constituant en corporation: Lucie Trudeau.7175.Christophe-,'olomh, Nessic Borland.1850.Lincoln, et Pauline Tylko, 3505, (iirouard.toutes trois secrétaires, lilies majeures, de Montréal.pour les objets suivants: Exploiter une compagnie dc portefeuille sous le nom de « Wrcnbury Holdings Ltd.», avec un capital total de $1,000.divisé en 1(H) actions ordinaires de .$10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-srcrélairc de la prorince, Raymond Douville.25015 2003-08 World Wide Associates Inc.Notice is given that under Part I of the Compinics Act.letters patent, bearing dale the 71 h day of May.1008.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Seymour Machloviteh.341)5 Moun-tain.Montréul.Marvin Rosenhek.335 Grcnfoll, Mount Royal, both advocates, and Madeleine Jackson, secretary, wife separate as to propertji of Nelson Jackson, 575 Laurent ian.Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on the general business of theatrical agents, theatre proprietors, builders, operators and managers, under the name of \"World Wide Associates Inc.\".with a total capital slock f $40.000, divided into lD.OOO common share- of $1 each and 30.000 preferred shares of $1 each.The head ollice of the company is at Moid real, judicial district of Montreal.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015-o 2021-08 Wrenbury Holdings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, hearing dale the 7lh day of May, 1008.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Lucie Trudeau.7175 Christophe-Colomb.Nessic Rolland.I860 Lincoln, ami Pauline Tylko, 3505 (iirouard.all three secretaries, filles majeures, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Wrenbury Holdings Ltd.\".with a total capital stock of Si.OOO, divided into 100 common shares of $10 each.The head office of the eonqiany is al Montréal, judicial district of Montréal.Raymond Doi villi:.Assistant Secretan/ of the Prorince.25015-o 200348 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Archway Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour d'avril 196S, à la compagnie « Archway Ltd.», augmentant son capital dc $15,000 à $100,000, le Capital addit ionnel étant divisé en 8,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douvillk.25015 11910-55 \u2014 1420,70 Campbell & Cameron Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur tic lu province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 14e jour de mai 1968, à la compagnie « Campbell & Cameron Ltd.», diminuant son capital de $240,000 à $94,250, le capital-actions annulé étant divisé en 14,575 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chucune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015 10007-55 \u20141422/40 Archway Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paient, bearing date the 26th day of April, 1908, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Archway Ltd.\", increasing its capital from $15,000 to $100,000, the additional capital stock being divided into 8,500 preferred shares of the par value of $10 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25015-o 11910-55 \u2014 1420/70 Campbell & Cameron Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 14th day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Campbell & Cameron Ltd.\", reducing its capital from $240,000 to $94,250, the capital stock annulled being divided into 14,570 preferred shares of the par value of $10 each.Raymond Douvillk, Assistant Secretary of the Province.25015 o 1OO07-55 \u2014 1422/40 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 22, 1968, Vol.100, No.25 3365 Centre Mgr BoufTard inc.Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il a été accordé, par le licutenant-pnivcrneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour dc mai 196S, à la corporation « Centre Mgr BoufTard inc.», étendant ses pouvoirs.Le toua-aecrétaire de la province, Raymond Dor vii.i.k.2ÔOI5-0 4584-66 \u20141420/128 Centre Mgr BoufTard inc.Notice is hereby given that pursuant to the Companies Act, the Lieutenant-Governor oT the Province granted supplementary letters patent dated the 1st day oT May, 1968, to \"Centre Mgr lloulTard inc.\", extending its powers.Raymond Douvillk, Assistant Secretan/ of the Province.25015 4584-66\u2014 1420/128 College Stc-Marie Pavillon Emile-Gérard inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le lieutenant-gouverneur de la province, des lettres patentes .iippl.'nientaires en date du 30e jour d'avril 1968, à In corporation « Collège Ste-Maric \u2014 Pavillon fanilc-fiérard inc.», modifiant les dispositions de ms lettres patentes.Le sous-secrflaire dc la province, Raymond Douvillk.25015-o 679-6S \u20141421/5 Doll Park Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partir de la Loi des compagnies, le licutcnant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2c jour de mai 1968, à la compagnie « Doll Park Ltd.», I réduisant son capital de 60,000 actions ordinaires sans valeur au pair à 600 actions orilinaires sans valeur au pair, le capital-actions annulé étant divisé en 59,400 actions ordinaires suis valeur au pair; 2° augmentant la considération pour laquelle les actions sans valeur au pair |>ourront être émises dc 860,000 à 8100,000.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 4415-67 \u2014 1421/110 College Ste-Maric Pavillon Emile-Gérard inc.Notice is hereby given that pursuant to the Companies Act, the Lieutenant-Governor of the Province granted supplementary letters patent dated the 30th day of April, 1968, to \"Collège Stc-Marie \u2014 Pavillon Émilc-Gcrard inc.\", amending the provisions of its letters patent.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.2.5015 679-68 \u2014 1421/5 Doll Park Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of May, 196S, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Doll Park Ltd.\", 1.reducing its capital from 60,000 common shares without par value to 000 common shares without par value, the annulled capital shares being divided into 59,400 common shares without par value; 2.increasing the consideration for which the shares without par value may be issued from §60,000 toSlOO.OOO.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 4415-67 \u2014 1421/110 Hunter Douglas International Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 22e jour de septembre 1967, il la compagnie « Hunter Douglas International Ltd.», modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 11405-59\u2014 1421/6 Hunter Douglas International Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 22nd day of September, 1967, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Hunter Douglas International Ltd.\", modifying the provisions of its letters patent.Raymond Douvii.i.i., Assistant Secretary of the Province.25015-o 11405-59\u2014 1421/6 Leon DuBrow Corporation Am- est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 9c jour de mai 1968, à la compagnie « Leon DuBrow Corporal ion », augmentant son capital de $5,000 à $45.000, |e capital-actions additionnel étant divisé en 40,000 actions privilégiées d'une valeur an pair de $1 chacune.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.'-'\u20225015 10333-56\u20141422/45 Les Entreprises de Nettoyage d'Édifices limitée Leon DuBrow Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, l>caring date the 0th day of May, 1968, ' have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Leon DuBrow Corporation\", increasing its capital from $5.000 to $45,000, the additionnai capital stock being divided into 40,000 preferred shares of the par value of $1 each.Raymond Douville, Assistant Secretan/ of the Province.25015-o 10333-56\u20141422/45 Les Entreprises de Nettoyage d'Edifices limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day.of May, 1968, have been Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres 3300 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1068, 100' année, n° 25 patentes supplémentaires en ilatc du 7e jour de mai 1968, ù la compagnie « Les Entreprises de Nettoyage d'Edifices limitée », étendant ses pouvoirs.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015-o 13752-60\u2014 1420/129 issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Les Entreprises de Nettoyage d'Édifices limitée\", extending its powers.Raymond Douville, Assistant Secretan/ of the Prorince.25015 13752-60\u2014 1420 129 Ferme Charo ltée Cliaro Farm Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc lu Ixii des compagnies, le licutcnnnt-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1968, à la compagnie * Ferme Charo ltée \u2014Cliaro Farm Ltd.», augmentant son capital de $70.000 à $140.000.le capital-actions additionnel étant divisé en 700 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 cliacune.Le sous-secrétaire dc la province, Raymond Douville.2Ô015-o 12802-56\u2014 1421/54 Ferme Charo ltée Cliaro Farm Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 30th day of April.196S.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Ferme Cluiro ltée \u2014 Charo Farm Ltd.\", increasing its capital from $70,000 to $140.000, the additional capital shares being divided into 700 preferred slmres of a par value of $100 each.Raymond Douville, Assistant Secretary or the Province.25015 12802-56\u2014 1421 54 Les Fermes du Cup St-Jacques liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour d'avril 1908.à la compagnie « Les Fermes du Cap St-Jacques liée .réduisant son capital de $3.200.000 à $422.400.le capital-act ions annulé étant divisé en 27,770 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-secrêtaire de la prorince.Raymond Doc ville.25015-o 11414-57\u2014 1420.78 Les Fermes du Cap St-Jacques ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, bearing date the 25th day of April, 10881 have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Ia-s Fermes du Cup St-Jacques ltée-\".reducing its capital stock from 83.200.000 to $422.400.the cancelled share capital being divided into 27.770 preferred shares of a par value of $100 each.Raymond Dorvn.i.r.Assistant Secretan/ of the Prorince.25015 11414-57 - 1120/78 Y von Fournicr limitée Avis est donné qu'en vertu de In première parti.' de la Loi îles compagnies, le liciitcnant-gouvcrneiir de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 7e jour de niai 1908.à la compagnie « Yvon Founder limitée », étendant ses pouvoirs.Le sous-secrétaire de la prorince, Raymond Doi vii.i.k.250I5-o 426-03 \u2014 1421/55 Garant inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compignics.le licutenant-gouverneiir de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour de mai 1968.A la compngnie «Garant inc.».1° augmentant son capital de $109.000 à $124.900.le capital-actions additionnel étant divisé en 15.000 actions privilégiées classe « A - «le $1 chacune: 2° subdivisant ses 308 act ions ordinaires dc $50 chacune en 3.989 actions ordinaires dc $5 chacune: 3° restreignant le droit de vote des détenteurs d'actions privilégiées classe « A ».Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvillk.25015-o 0487-43 - 1421/98 Yvon Fournicr limitée Notice is given tliat, under Part I of the Companies Act, supplementary letters pilent, hearing date the 7th day of May.1608, bave been issued by the Lieutcnant-Governor of the Province lo \"Yvon Fournicr limitée\", extending its powers.Raymond Dor villi:.Assistant Secretan/ of the Prorince.25015 426-68\u20141421/55 Garant inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters pilent, bearmg date the 3rd day of May.1968.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Garant inc.\".1.increasing its capital stock from $109.900 to $124.900.lite additional share capital being divided into 15,000 preferred class \"A\" shares of $1 each: '-\u2022 subdividing its 398 common shures of ISO each into 3,980 common shores of $5 each: 3.restricting the voting right of holders of preferred class \"A\" shares.Raymond Douvillk.Assistant Sierctary of the Proriicc.25015 6487-43 \u2014 1421, OS Hellenic Poultry Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la premiere pai lie de la Loi des com|Nignics, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour de Hellenic Poultry Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companion Act, supplementary letters patent, hearing date the 1st day of May, 1968, liavc bees issued by the Lieutenant-Governor of the Prov- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3367 mai 1068, ù la compagnie « Hellenic Poultry Co., 1° diminuant son capital de $40,000 à $20.000, le capital-actions annulé étant divisé m 200 actions privilégiées d'une valeur au piir île $100 chacune; 2° augmentant son capital de $20,000 ù $1,520,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 150,000 actions catégorie \u2022 A de $10 chacune; 3° modifiant les dispositions de -es lettres patentes; 4° augmentant le nombre de ses administrateurs, dc 3 à 5.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.250LÏ-o 4174-64\u20141421/00 inec to \"Hellenic Poultrv Co.Ltd.\", 1.reducing its capital from $40,000\" to $20,000, the capital stock annulled l>eing divided into 200 preferred shares of the par value of $100 each; 2.increasing its capital from $20,000 to $1,520,000, the additionnai capital stock being divided into 150,000 class \"A\" slmres of $10 each; 3.modifying the provisions of its letters patent; 4.increasing the number of its directors from 3 to 5.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 4174-64\u2014 1421/99 Industrie Porcine du Québec limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant ¦ puveraeur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 23c jour d'avril 1968, a la compagnie « Industrie Porcine du Québec limitée », 1° redésignant ses 600 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 cliacune en 600 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pur de $100 chacune; 2° augmentant son capital de $100,000 à $200.000, le capital-actions additionnel étant divisé en 1.000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au |wir de $100 cliacune.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.2501.ï-o 14593-62- 1421/94 Industrie Porcine du Québec limitée Notice is given that, uni! t I of the Companies Act, supplements k .ters patent, bearing date the 23nl day oi April, 1968, liave lieen issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Industrie Porcine du Québec limitée\", 1.redesignating its 600 preferred shares of a pir value of $100 each 600 preferred class \"A\" shares of a par value of $100 each; 2.increasing its capital stock from $100,000 to $200.000, the additional share capital being divided into 1,000 preferred class \"B\" shares of a I>ar value of $100 each.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Prorince.25015 14593-62\u2014 1421/94 .Magnetics International Ltd.(No Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et de la Loi des compagnies minières, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 2c jour de mai 1968, à la compagnie « Cons.Quebec Smelting & Refining Ltd.(No Personal Liability) \u2014 Smel-tage & Affinage Cons, du Quebec ltée (Libre de respongabflrté personnelle) ».changeant son nom en celui de « Magnetics International Ltd.» (No Personal Liability).Lt sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douville.2.5915 6956-47 \u2014 1422/5 Magnetics International Ltd.(No Personal Liability) Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 2nd day of May, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Cons.Quebec Smelting & Refining Ltd.(No Personal Liability) \u2014 Smeltage & Affinage Cons, du Quéliec ltée (Librede responsabilité personnelle)\", changing its name to that of \"Magnetics International Ltd.\" (No Personal Liability)^ Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25915-0 6956-47\u2014 1422 5 Marché Union inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-Rouvcrneur dc la province a accordé des lettres païen tes supplémentaires en date du 16e jour d'avril 1968, à la compagnie « Marché Union inc.», 1° changeant ses 346,710 actions ordinaires émises d'une valeur au pair de $1 cliacune et ses 3,290 actions ordinaires non-émises d'une valeur au pair dc $1 chacune en 350,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair; 2° subdivisant ses 346,710 actions ordinaires émises saiiv valeur nominale ou au pair en 693,420 actions ordinaires émises sans valeur nominale ou au pair et ses 3,290 actions ordinaires non-émises sans valeur nominale ou au pair en 6,580 actions ordinaires non-émises sans valeur nominale ou au pair; 3° augmentant son capital par la création de 300,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair.Ta! sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25015 11017-58- 1421/103 Marché Union inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Marché Union inc.\", 1.changing its 346,710 issued common shares of the par value of $1 each and its 3,290 unissued common shares of the par value of $1 each into 350,000 common shares without nominal or par value; 2.subdividing its 346,710 issued common shares without nominal or par value into 693,420 issued common shares without nominal or par value and its 3.290 unissued common shares without nominale or par value into 6.580 unissued common slmres without nominal or par value; 3.increasing its capital by the creation of 300,000 common sliares without nominal or par value.Raymond Douvii.i.i:, Assistant Secretary of the Province.25015-o 11017-58 \u2014 1421/103 CA7.ETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin IOCS, 100 \u2022 année, «\u2022 25 Ouellet & Labcrge (limitée) Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du l()c jour de mai 1968, à la compagnie « Ouellet & Lahergc (limitée) », augmentant son capital de 820,000 à 880,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 6,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le sous-sccrclairc île la province, Raymond Douvii.llk.25015-0 1686-38 \u2014 1422/35 Ouellet & Labcrge (limitée) Notice is given that, under l'art I of the Companies Act, supplementary letters patent, hearing date the 10th day of May, 100S.have heen issueil by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Ouellet & Lahergc (limitée \", increasing its capital stock from $20,000 to $80,000, the additional share capital being divided into 0,000 preferred shares of $10 each.Raymond Douvii.i.k.Assistant Secretary of the Province.25015 1686-38 \u2014 1422 36 Les Petites Soeurs dc l'Assomption incorporée Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le liculcnaiil-gouverneur de la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 30e jour d'avril 1908, à la corporation « Les Petites Soeurs dc l'Assomption incor|>oréc », augmentant le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation dc SlOO.OOO à $100,000.Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.25015-0 328-34 \u20141421/108 Les Petites Soeurs dc l'Assomption incorporée Notice is hereby given that pursuant to the Companies Act, the Lieutenant-Governor of I lie Province granted supplementary letters paient dated 30th dny of April, 1968, to \"Le» Petites Soeurs de l'Assomption incorporée\", increasing the amount to which is limited the immovable property which the said corporation may acquire and possess from $100,000 to $400,000.Raymond Douvii.i.i:.Assistant Secretary of the Province.25015 328-34 \u2014 112 HO.) Sandra Children's Vicar Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 7e jour de mai 1968.à la compagnie c Sandra Children's Wear Inc.augmentant son capital de 820,000 à $00,000.le capital-actions additionnel étant divisé en 40.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le sous-seerétairc de la prorince.Raymond Doi vii.i.k.25015 2875-44 -1421/24 Simard International inc.Avis est donné qu'en vertu île la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 8c jour de mai 1908.ù la compagnie \u2022 Simard International inc.augmentant son capital de $100.000 à $500,000, le capital-actions additionnel étant divisé en 40.000 actions privilégiées de $10 chacune./.c sous-secrétaire dc la prorince, Raymond Douvillk.25015-o 3094-03 - 1421/70 Sandra Children's Wear Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act.supplementary letters patent, licaring date the 7lh day of May.1008.have Urn issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Sandra Children's Wear Inc.\".increasing its capital from $20.000 to $150.(100.the additional capital slock being divided into 40.IHHI preferred shares of the par value of $1 each.Raymond Doi\u2022 vii.i.k.Assistant Secretan/ of the Province.2.5015.) 2875-44 - 142124 Simard International inc.Notice is given that, under Part I of I lie Companies Act, .supplementary letters patent, bearing dale the 8th day of May.1908.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Simard International inc.\".increasing its capital stock from 8100,000 I\" $500.000.the additional share capital being divided into 40,000 preferred shares of $10 each.Raymond Douvillk.Assistant Secretan/ of the Province.25015 3094-03 - 142170 Vietoriaville Upholstering Ltd.Rcmliourrage Vietoriaville ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 1er jour de mai 190S.à la compagnie « Vietoriaville Upholstering Ltd.HciulKHirragc Vietoriaville liée », augmentant son capital de $105.000 ù $215.000, pur la création de 5.000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune 7,«r sous-secrêtaire de la prorince.Raymond Doi vii.i.k.25015-o 15741-00 - 1420/102 Vietoriaville Upholstering Ltd.Rembourrage Vietoriaville ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters paient, hearing date the 1st day of .Slay.1968, have Itccn issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Vietoriaville Upholstering Ltd.Rembourrage Vietoriaville liée\", increasing ils capital stock from $165,000 to 8216,000; by Uic creation of 5.000 preferred shares of a par value of $10 each.' Raymond Douvillk.Assistant Secretary of the Province.25015 15741-60 \u2014 1420/102 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, IOCS, Vol.100, No.25 3369 960 Victoria Square Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie tie la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé «les lettres patentés supplémentaires en date du 29e jour ,l'avril 1968, à la compagnie « 960 Victoria Square Inc.», augmentant son capital dc \u202240,000 à $160,000.le capital actions additionnel étant divisé en 4,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le sous-secrétairc dc la province, Raymond Douvillk.25015 12776-56\u20141420/101 960 Victoria Square Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of April, 1968, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"960 Victoria Square Inc.\", increasing its capital from $40.000 to $460.000.the additionnai capital stock being divided into 4,200 preferred shares of the par value of $100 each.25015-o Raymond Douvillk, \\] Assistant Secretan/ of the Province.12776-56\u20141420/101 Arrêtés en Conseil Orders in Couneil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1705 Québec, le 6 juin 1968.Présent; I.c Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif à l'industrie de la construction dans les régions lie Saint-Hyacinthe.Saint-Jean, Granby.Ai ri.m>i' que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts Refondus du Québec 1964, chapitre 143 .les parties contractantes à ht convention collective de travail relative à l'industrie dc la construction dans les régions de Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Granby, rendue obligatoire par le décret numéro 210 du 3 février 1967 et amendements, ont présenté un ministre du Travail une requête à l'clfcl de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée ilai - la (iazilte officielle de Québec, édition du 27 avril 1968: Attendu que, conformément aux dispositions de ladite Loi.des parties contractantes au décret numéro 210 du 3 février 1967 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans les régions de Saint-Hyacinlhc.Saint-Jean, Granby, mil présenté au ministre du Travail une requête à l'effet d'instituer un régime de sécurité sociale; attendu que ladite requête a été publié dans la limette officielle de Québec édition du 20 avril 1008; Attendu qu'aucune objection n'a été formulée contre l'upporhntion des modifications proposées; ii.est ou donné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: que ledit décret, numéro 210, soit modifié comme suit: 1° Le paragraphe 11.04 est Lille.2\" Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 28: 28.09 La priorité d'emploi doit être donnée aux apprentis d'un centre d'apprentissage L'apprenti ne doit pas faire le travail d'un manoeuvre.28.10 Le nom de loul apprenti doit être inscrit \u2022huis un registre tenu par le comité paritaire Ledit registre doit mentionner le nom.prénoms, l'âge et T'adresse de l'apprenti, contenir aussi lu date du commencement de l'apprentissage et la preuve dc continuité de la formation de l'appren- Ordcr in Couneil Executive Couneil Chamber Number 1705 Québec, June 6, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.CONCERNING amendments to the decree respecting the Construction Industry in the St.Hyacinthe, Saint Jean, Granby regions.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Construction Industry in the St.Hyacinthe, St.Jean, Granby regions (made binding by Decree number 216 of February 3, 1907, as amended) have petitioned the Minister of Labour to submit certain amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision; Whereas the petition was published in the Quebec Official Gazette ol April 27, 1968; Wiikreas, pursuant to the provisions of the said Act.contracting parties to decree number 216 of February 3.1967, as amended (Construction Industry in the St.Hyacinthe, St.Jean, Granby regions) have petitioned the Minister of Labour to establish a social security plan ; Whereas the petition was published in the Quebec Official Gazelle of April 20, 1968; Whereas no objection was brought forth against the approval of the proposed amendments; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That said Decree number 216 be amended as follows: 1.Subsection 11.04 is abrogated.2.The following subsections are added to section 28: \"28.09 Apprentices from an apprenticeship centre shall he favoured with preferential employment.No apprentice may do labourer's work.28.10 Apprentices' names shall be entered in a register kept by the Parity Committee.Such register shall mention: the apprentice's given names, family name, age and address; the date on which apprenticeship began and proof of the apprentice's continuity of training; the name 3370 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 ti, le nom et l'adresse de son premier employeur et dc tous les employeurs successifs jusqu'à la fin dc lu période d'apprentissage.28.11 Le comité paritaire doit fournir à chaque apprenti un carnet d'apprentissage dans lequel doivent être indiquées les dates de commencement et dc Cessation du service dc l'apprenti chez chacun «les employeurs où il fait son apprentissage 28.12 Aucun employeur ne peut employer sur un chantier déterminé plus d'un (1) apprenti |X)ur cliaqiic comiiagnon dans les métiers dc possui de linoléum, «le carreleur et des autres poseurs «le revêtements de sol.«le vitrier et.de serrurier et menuisier de menuiserie métallique (travailleur en fer et bronze d'ornementation).28.13 Toutefois, il peut y avoir un (1) apprent i pour trois (3) compagnons ou fraction dc ce nombre travaillant sur un chantier déterminé dans les métiers de hriquetcur.mnçon.plâtrier.ehar|>cntier-mcnuisier et peintre 28.14 Aucun employeur ou employeur professionnel ne peut faire travailler un apprenti Seul et aucun apprenti ne peut travailler seul à l'exécution de travaux relevant des métiers; il doit toujours être accompagné enses incurred for record-keeping shall be defrayed by the social security fund.Division 5 The Social Securily Committee 10.00 Formation 10.01 The social security committee is made up of six (0) memltcrs: three (3) shall be employer representatives and three (3) sliall be employée representatives.They sliall be appointed according to the procedure set forth in sections 17.00 and 18.00 of this division.10.02 However, upon the effective date of the present Part, the committee set up under the collective agreement whose legal extension is hereby ensured, acquires legal status just as though it had been appointed under this division.17.00 Appointment of Employer Representative 17.01 Each employer representative is appointed as follows: (a) L'Association des Constructeurs dc Saint-Hyacinthe, Itagot, Rouville.l'Association dei Constructeurs de la l'allée du Richelieu Inc.aiul T Association des Entrepreneurs en Construction dc llrome, Missisquoi, Shcfford (Ilcdford district) each appiint an employer representative Each aforementioned association shall file a duly-certified certificate of appointment with the Parity Committee.(b) At the regular meeting that follows receipt of such certificate, the Parity Committee shall appoint the reprcsentativc(s) so nominated and shall immediately advise them thereof in writing.It shall also immediately make the appointments known to the social security committee.(c) At the regular meeting that immediately follows receipt of such notice, the social security committee secretary shall make such appomt-mcnt known.(if) Each appointed representative shall take oflice at the meeting following the one when the social security committee was advised of the appointments and he sliall be indemnified for his services.18.00 Appointment of Employee Représentantes 18.01 Each employee representative is appointed as follows: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22.1968, Vol.100, No.25 3377 a) Le Syndicat national des métiers dc la Coast ruction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.); le gyndh at catholique national de la Construction de Saint-Jean Inc.(C.S.N.) et le Syndicat national f| catholique des métiers de la Construction dc Granby Inc.(C.S.N.) désignent chacun, un représenta ' des salariés.Chacun dc ces syndicats transmet nu comité paritaire le certificat dc désignation dûment attesté.b) À ['assemblée ordinaire qui suit immédiatement la réception d'un tel certificat, le comité paritaire nomme le ou les représentant/s ainsi désigné/s et informe immédiatement par écrit les intéressés.Il en avise sans délai, par écrit, le comité de sécurité sociale.e) A l'assemblée ordinaire qui suit immédiatement la réception de tel avis, le secrétaire du comité île sécurité sociale doit faire part dc telle nomination.il¦ Chaque représentant nommé entre en fonction à rassemblée qui suit celle où le comité île sécurité sociale a été avisé des nominations et reçoit une indemnité à titre dc compensation pour ses services.19.00 Ttrme d'office des représentants 19.01 Tout représentant et tout successeur ¦l'iiii représentant doit remplir sa charge jusqu'à la date de sa démission, de son décès, de son incapacité ou de son retrait, tel que prévu ci-après.'20.00 Démission d'un représentant 20.01 l'n représentant peut démissionner et être libéré de toutes obligations futures ou dc Imité charge prévue aux présentes en remettant un avis écrit de sa démission au comité paritaire, l'ne copie dc tel avis doit être délivrée à la partie contractante qu'il représente par le secrétaire du comité paritaire.21.00 Remplacement d'un représentant 21.01 Tout représentant des employeurs ou des salariés est démis de ses fonctions lorsque la partie contractante qui l'a nommé donne un avis écrit à cet effet au comité paritaire, avec copie au comité de sécurité sociale.22.00 Vacance au comité 22.01 Si un poste devient vacant, un successeur e-l nommé aussitôt que possible conformément aux dispositions des articles 17.00 et 18.00 dc la section 5 du présent titre.22.02 Dans l'esprit du présent titre, le comité de sécurité sociale doit compter en tout temps un nombre égal de représentants des salariés et dc représentants des employeurs mais, s'il y a un ou plusieurs postes vacants, les représentants en 'onction ont le pouvoir d'agir jusqu'à la nomination d'un ou plusieurs successeurs, selon les dispositions du présent titre.Section 6 Bureau du comité dc sécurité sociale 23.00 Élection du bureau et engagement du secrétaire 23.01 Après la nomination des représentants, le comité dc sécurité sociale se réunit aussitôt lue possible et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président parmi les représentants, l'ar la suite, le comité de sécurité sociale élit entre le 1er et le 15 mars de chaque année, un president et un vice-président parmi les représentants.En tout temps, l'une des deux fonctions esl occupée par un représentant des salariés et (a) Le Syndicat national des métiers de la Construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.), le Syndicat catholique national de la Construction de Saint-Jean Inc.(C.S.N.) and le Syndical national et catholique des métiers de la Construction de Granby Inc.(C.S.N.) each appoint an employee representative.Each aforementioned trade union shall file a duly-certified certificate of appointment with the Parity Committee.(b) At the regular meeting that immediately follows receipt of such certificate, the Parity Committee shall appoint the representative(s) so nominated and sliall immediately advise them thereof in writing.It shall also immediately make the appointments known to the social security committee in writing.(c) At the regular meeting that immediately follows receipt of such notice, the social security committee secretary shall make such appointment known.(d) Each appointed representative sliall take olfiee at the meeting following Oie one when the social security committee was advised of the appointment!sj and he shall be indemnified for his services.19.00 Re présentât ires' Term of Offices 19.01 Each representative and successor-representative shall serve until the date of his resignation, death, incapacity or retirement as hereinafter provided.20.00 Re présentai ire's Resignation 20.01 A representative may resign and be discharged from all future duty or responsibility herein provided for by filing a written resignation with the Parity Committee A copy of such resignation shall be forwarded to the contracting party he represents by the secretary of the Parity Committee.21.00 Replacement of a Représentante 21.01 An employer or employee representative may be removed upon written recommendation to the Parity Committee by the party tliat appointed him, with copy to the social security committee.22.00 Vacancy on the Committee 22.01 Should a vacancy occur, a successor shall he immediately appointed in accordance with the provisions of section 17.00 and 18.00, Division 5, Part Five.22.02 It is the intention hereof that the social security committee shall at all times be made up of an equal number of employee and employer representatives.In the event of a vacancy or vacancies, the remaining representatives sliall have the power to act until the appointment of one or more representatives, as provided for in the provisions of this Part.Division 6 Officers of the Social Security Committee 23.00 Election of Officers and Hiring of a Secretary 23.01 As soon as possible after the appointment of representatives, the social security committee shall meet and elect a chairman and vice-chairman from among the representatives.Thereafter, between March 1st and 15th of each year, the social security committee shall elect a chairman and vice-chairman from among the representatives.At all times one of the two offices shall be held by an employee representative 3378 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n°25 l'autre par un représentant des employeurs.L'ordre d'élection doit être établi dc façon que les parties contractantes soient représentées tour à tour à la présidence et pour des termes égaux d'une (1) année.23.02 Le comité de sécurité sociale engage un secrétaire pour tenir les procès-verbaux dc ses assemblées.Celui-ci peut également être chargé du secrétariat.24.00 Terme d'office des membres du bureau 24.01 Le terme d'ollicc du président et du vice-président commence à la date de leur élection et se continue à partir de cette date jusqu'à la nomination de leur successeur.Nonobstant ce qui précède, à l'entrée en vigueur du présent régime de sécurité sociale, le premier président et le premier vice-président seront en fonction jusqu'à l'élection dc leurs successeurs lors dc la première élection qui aura lieu entre le 1er et le 15 mars 1970.Le premier président à être élu doit être choisi parmi les représentants des employeurs, et le premier vice-président parmi les représentants «les employés.L'ordre d'élection établie à l'article 23.01 sera par la suite observé.25.00 Remplacement des membres du bureau 25.01 Si, pendant son terme d'ollicc, le prési-«lent décède, démissionne ou se retire, son substitut doit être choisi parmi les représentants dc lu partie contractante que représentait le président remplacé.Dans ce cas, le terme d'ollicc du président substitut dure jusqu'à l'expiration du terme d'ollicc du président remplacé.La même procédure s'applique «lans le cas du vice-president.Section 7 Assemblée du comité de sécurité sociale 26.00 Convocation 26.01 Les assemblées du comité de sécurité sociale sont tenues à l'endroit et aux dates dont peuvent convenir d'avance les membres du ( 'omité sinon elles p«*uvent être tenues à l'endroit et aux dates dont peuvent convenir ensemble le président et le vice-président.Elles peuvent «'\u2022gaiement être convoquées par lesdiLs président et vice-président au moyen d'un avis écrit dc cinq (5) jours, adressé aux autres représentants et peuvent être tenues en tout temps sans cet avis si tous les représentants y consentent par écrit.Trois (3) représentants peuvent ensemble présenter par écrit au président, au vice-président ou au secrétaire une demande à l'effet de faire convoquer une assemblée et, dans ce cas, le président et le vice-président doivent convoquer une assemblée dans les dix (10) jours suivant une telle demande.27.00 Quorum 27.01 À toute les assemblées du Comité de sécurité sociale, quatre (4) représentants constituent le quorum pour l'expédition des affaires, pourvu qu'il y ait au moins deux (2) représentants «les employeurs présents à ces assemblées et au moins deux (2) représentants des salariés.28.00 Vote 28.01 Toute action qui doit être prise par le comité de sécurité sociale, selon les termes du présent titre, doit l'être par vole unanime des représentants présents à l'assemblée.and the other by an employer representative.The ortlcr of election is such that the contracting parties are represented alternately in the presidency for equal one-year terms.23.02 The social security committee shall lure a secretary to take minutes of its meeting-.The secretary may also be in charge of the secretarial staff.24.00 Officers' Term of Office 24.01 The chairman's and vice-chairman's term of office begins on the date of their election nnd continues therefrom until their successor has l>een appointed.Notwithstanding the foregoing, on the effective date of this social security plan, the first chair-man and vice-chairman shall remain in ollice until their successors arc elected at the first election which should take place between March 1st ami 15th.1970.The first chairman elected shall l>c « ho sen from among the employer representatives and the first vice-chairman from among the employee representatives.The order of election set forth in subsection 23.01 shall l>c adhered to thereafter.25.00 Replacement of Officers 25.01 If, during his term of oflice, the chairman dies, resigns or retires, his successor shall Ik-chosen from nmong the representatives of the outgoing chairman's contracting party.In such instance, the term of office of the successor, chairman shall last until the expiration of the outgoing chairman's term.The same procedure shall be followed in the case of a vice-chairman.Division 7 Meetings of the Social Security Committee 26.00 Notice of Meeting 20.01 Mcetingsof the social security committee shall be held at such place and on such date- as may be agreed upon the Committee members.Otherwise they may be held at a place and OS such dates as may l>e agreed upon by the chairman and vice-chairman.Meetings may also he called by the chairman and vice-chairman upon five (5) days' written notice to the other representatives and may l>c held at any time without such notice if all the representatives consent thereto in writing.Any three (3) représenta lives may present a written request to the chairman, the vice-chairman or the secretary that a meeting he called and, in this even, the chairman and vice-chairman shall call a meeting within ten (10) days after such request.27.00 Quorum 27.01 In all social security committee meetings, four (4) representatives shall constitute a quorum for the transaction of business, providing at least two employer representatives and at least two employee representatives be present at such meetings 28.00 Vote 28.01 Any action to be taken by the social security committee, pursuant to this Part shall be by unanimous vote of the representatives present at the meeting. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3379 28.02 11 n'y a que deux votes: les représentants des employeurs se partagent un vote entre eux, et les représentants des salariés se partagent un vole entre eux.Le vote des représentants des salarie, est donné par la majorité des représentant- des salariés présents et votants; le vote des représentants des employeurs est donné par la majorité des représentants des employeurs présent- et votants.28.03 Si une affaire présentée pour décision ne peut être décidée à cause d'un vote égal, elle demeure dans le statu quo pendant l'arbitrage selon la procédure prévue à la section 8 du présent titre o moins que, par un vote unanime, on décide de blister tanner l'affaire.20.00 l'rocès-rerbaux 20.01 Toute décision prise par le comité de akurité sociale doit être inscrite au procès-verbal de la -éanec où cette décision a été prise.Le secretaire doit transmettre une copie certifiée conforme des procès-verbaux aux parties contractantes sur demande.Section 8 Arbitrage 30.00 Procédure d'arbitrage et choix de l'arbitre 30.01 Si le comité de sécurité sociale ne peut pu décider d'une affaire ou résoudre un litige à DUC d'un vote égal ou, si les décisions ne peuvent être prises parce que le quorum ne peut être realise à deux (2) assemblées successives au comité de sécurité sociale, alors et dans l'un ou l'autre de te Ilea éventualités, la procédure d'arbitrage s'applique et le comité de sécurité sociale choisit un arbitre impartial qui entend et détermine l'alfaire ou le litige.31.00 Nomination de l'arbitre par la cour 31.01 Si les représentants ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre impirtial dans les cinq (5) jours qui suivent le jour où ils ont tenté ili' procéder à la sélection, la Cour Provinciale du district de Granby doit désigner un arbitre impartial.Deux (2) représentants peuvent requérir la < our Provinciale du district de Granby de désigner un arbitre.32 00 Audition du litige et sentence arbitrale.32.01 L'affaire en litige doit être entendue dans le» dix (10) jours dc la date à laque le l'arbitre a été choisi ou désigné.La décision ou la sentence dc l'arbitre doit être par écrit, sans appel et lier ton Us les parties et tous les intéressés et doit être rendue dans les dix (10) jours ouvrables enn - que l'arbitre a reçu toute la preuve.L arbitre, dans sa décision ou sa sentence, est lié par les dispositions du présent titre et n'a ni le pouvoir ni l'autorité d'ajouter ou de soustraire quoi que ce soit au présent titre, d'en changer ou d'en modifier les dispositions.Section 9 Limitation de responsabilité 33.00 Responsabilité du comité de sécurité sociale 33.01 Le comité de sécurité sociale et les représentants des parties contractantes ne peuvent être tenus responsables d'une erreur de jugement ni d'aucune perte résultant de tout acte ou de toute omission dans l'administration de la caisse 28.02 There shall be but two votes: the employer representatives shall share one vote and the employee representatives shall share one vote.The vote of the employee representatives shall be cast by the majority of employee representatives present and voting.The vote of the empjoyer representatives sliall be cast by the majority of employer representatives present and voting.28.03 If any matter submitted for decision cannot be decided because of a tie vote, the matter shall remain in status quo pending arbitration as set forth in Division 8 hereof, unless it be decided by unanimous vote to dismiss the matter.29.00 Minutes 29.01 Any decision taken by the social security committee shall be entered in the minutes of the meeting during which the decision was taken.A certified copy of the minutes of the meeting shall be forwarded, upon request, to the contracting parties by the secretary.Division 8 Arbitration 30.00 Arbitration Procedure and Choice of Arbitrator 30.01 In the event the social security committee cannot decide any matter or resolve any dispute because of a tie vote, or in the event decisions cannot be made because of the lack of a quorum at two (2) successive meetings of the social security committee then, and in either of such events, the arbitration procedure shall apply and the social security committee shall select an impartial arbitrator to hear and determine the issue or dispute.31.00 Court Appointment of Arbitrator 31.01 If the representatives cannot agree on an impartial arbitrator within five (5) days from the day they have attempted to select him, an impartial arbitrator shall be designated by the Provincial Court of the District of Granby.Any two (2) representatives may request the Provincial Court of the District of Granby to designate an arbitrator.32.00 Hearing of Dispute and Arbitration Award 32.01 A hearing on the disputed matter shall be held within ten (10) days from the date the arbitrator has been selected or designated.The arbitrator's decision, or award shall be final and binding upon all parties and persons concerned.It shall be handed down in writing within ten (10) working days after the arbitrator has received all the evidence.The arbitrator, in his decision or award, shall be bound by the provisions of this Part and shall not have the power or authority to add to or subtract anything from this Part or to change or modify the provisions thereof.Division 9 Limitation of Liability 33.00 Responsibility of the Social Security Committee 33.01 Neither the social security committee nor the representatives of the contracting parties shall be liable for any error in judgment or for any loss arising from any act or omission in the administration of the retirement fund or 8380 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 19G8, 100' année, n° 25 dc retraite ou du Régime dc rente de retraite et de la caisse d'assurance-vic collective ou du régime d'assurance-vic collective et dans l'administrai ion des dossiers, que le comité de sécurité sociale assume telle obligation ou qu'il l'ait confiée à un tiers, et ils ne sont personnellement responsables d'aucune obligation ou dette du comité de sécurité sociale contractée ou encourue par ce comité', ni d'aucune autre obligation résultant de l'administration ou de l'existence du fonds de sécurité sociale ou qui y est rattachée.33.02 Cependant, le présent article n'a pas pour effet dc soustraire ces représentants à la responsabilité résultant d'obligations ou dettes produites par leur action ou omission accomplie ou subie de mauvaise foi ou par négligence grossière ou inconduite délibérée.34.00 Responsabilité du comité paritaire 34.01 Le comité paritaire et ses représentants ne peuvent être tenus personnellement responsables d'aucune erreur de jugement ni d'aucune perte résultant de tout acte ou de toute omission concernant la perception ou le recouvrement des contributions, ni de toute autre obligation attachée à l'administration des dossiers du fonds de sécurité sociale, ou en résultant, si tel est le cas.Le comité paritaire et ses représentants ne sont nullement responsables d'aucune obligation ou dette du comité de sécurité sociale contractée ou encourue par cedit comité, ni d'aucune autre obligation attachée à l'administration ou à l'existence du fonds dc sécurité sociale, de la caisse de retraite et dc la caisse d'assurance-vie collective ou qui en résulte.Toute responsabilité quant à l'administration du fonds de sécurité sociale et quant à l'administration et au fonctionnement de la caisse de retraite et de la caisse d'assurance-vic collective incombe au comité de sécurité sociale.Cependant, le présent article n'a pas |>our effet dc soustraire le comité paritaire ou ses représentants et auncun d'entre eux à lu responsabilité résultant d'obligations ou dettes produites par leur action ou omission accomplie ou subie de mauvaise foi ou par négligence grossière ou inconduite délibérée dans l'exercice dc leurs fonctions.,35.00 Responsabilité des parties contractantes 35.01 Rien dans le présent titre ne peut être interprété comme rendant l'Association des Constructeurs de Saint-Hyacinthe, Ragot, Rou-ville; l'Association des Constructeurs de la Vallée du Richelieu Inc.; l'Association des Entrepreneurs en Construction dc Brome, Missisquoi, Shefford (district de Bedford); le Syndicat National des métiers dc la construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.); le Syndicat catholique national dc la construction de Saint-Jean Inc., (C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers de la Construction dc Granby Inc.(C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers du bâtiment de Cowansvillc Inc.(C.S.N.); la Fédération Nationale des Syndicats du Bâtiment et du Bois Inc.(F.N.S.b.B.) ou leurs représentants responsables du paiement de toute prestation résultant du fonds de sécurité sociale.36.00 Responsabilité des employeurs 36.01 Aucun employeur n'assume une responsabilité quelconque du fait de l'incapacité du comité de sécurité sociale de procurer les prestations prévues dans le présent titre pour tout salarié, ancien salarié ou bénéficiaire, ou du fait dc tout manquement ou de toute négligence du comité dc sécurité sociale.the retirement annuity plan and of the group life-insurance fund or the group life-insurance plan as well as in the administration of records, should it assume responsibility therefor or should it entrust it to a third party.They shall not be personally liable for any obligation or debt of the social security committee contracted or incurred by the said committee, nor for any obligation arising from the administration, existence of the social security fund or belonging thereto.33.02 However, this section shall nol l>e construed as exempting such representatives from any liability arising from obligation- or debts brought aliout by their action or omission accomplished or suffered in bad faith or through gross negligence or wilful misconduct.34.00 Responsibility of the Parity Committee 34.01 Neither the Parity Committee nor its representatives shall be held personally liable for any error in judgment or for any loss arising from any act or omission in the collection or recovery of assessments, nor of any obligation arising from or connected with the administration of the social security fund records, if such be the case The Parity Committee and its representatives are in no wuy liable for any obligation or debt of the social security committee contracted or incurred by the said committee nor for any other obligation resulting from or connected with the administration or existence of the social security fund, the retirement fund and the group life insurance fund.Any liability in connection with the administration of the social security fund or the administration and operation of the retirement fund and the group life insurance fund belongs to the social security committee However, this section shall not he construed as exempting the Parity Committee or its representatives, jointly and individually, from any liability arising out of obligations or debts brought about by their action or omission accomplished or suffered in bad faith or through gross negligence or wilful misconduct in the carrying out of their duties.35.00 llcsponsiblity of Uie Contracting Parties 35.01 Nothing in the present Part shall he construed as making l'Association des Constructeurs de Saint-Hyacinthe, Bayot, Banville: l'As» dation des Constructeurs de la l'allée du Richelieu Inc.; l'Association des Entrepreneurs en Construction de Brome, Missisquoi, Shefford, (Bedford district); le Syndicat national des métiers de '« construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.);It s cal catholique national de la construction de Stvnt-Jean Inc., (C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers de la construction dc Granby Inc.(C.S.N.): le syndicat national et tatkoliqm des métiers du bâtiment de Cowanscille /'f, (C.S.N.) : and la Fédération nationale des Si/mh-cals du Bâtiment et du Bois Inc.(FJI.8.BB-) or their representatives liable for the payment Ol any benefit provided for in the social security fund.36.00 Responsibility of Employers 36.01 No employer may be held liable for the failure of the social security committee to provide the benefits stipulated in this Part for any employee, former employee or beneficiary or for any default or neglect of the social security committee. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3381 37.00 Responsabilité ou égard aux documents 37.01 Le comité de sécurité sociale et chacun des représentants sont complètement protégés lorsqu'ils agissent en vertu d'un instrument, certifient ou document, qu'ils croient authentiques et qu'ils croient signés ou présentés par la ou les personnes appropriées et ils ne sont nulle-nieiit obligés de procéder à des enquêtes ou d'autrement vérifier une déclaration quelconque contenue dans de tels documents mais peuvent les accepter comme preuve concluante de la véracité et dc l'exactitude des déclarations y contenues.35.00 Responsabilité eu égard aux conseillers 38.01 Le comité de sécurité sociale peut de temps à autre consulter des conseillers reconnus et les représentants sont tout à fait protégés s'ib agissent conformément ou à l'encontre des avis des conseillers.Section 10 Obligations et pouvoirs du comité de sécurité sociale 39.00 Administration générale 39.01 Le comité de sécurité sociale voit à l'administration et à la bonne marche du régime de rente dc retraite et du régime d'assurance-vie collective, de la caisse de retraite et dc la caisse d'assurance-vie collective \u202210.00 Obligations du comité de sécurité sociale \u202210.01 Le comité dc sécurité sociale doit: a recevoir du comité paritaire le montant des cotisations et le verser, conformer aux présentes, à la caisse dc retraite et à la caisse d'assurance-vie colled ive respectivement; '0 publier et distribuer aux salariés une brochure décrivant les principales dispositions du régime de sécurité sociale avec un exposé de leurs droits et devoirs et tout autre renseignement prescrit par la Régie des rentes du Québec.41.00 Contrats ou ententes 11.1)1 Le comité de sécurité sociale doit, lorsqu'il s'agit de contracter des ententes: i\" faire un appel d'offres à au moins deux compagnies dc fidéicommis et deux compagnies d'as-siiraiice-vie relativement au régime de rente de retraite visé par les présentes, quant à l'administration de tel régime et au placement des actifs de la caisse dc retraite: b) faire un appel d'olîres à au moins deux compagnies dc fidéicommis relativement au régime d'assuranec-vie collective visé par les présentes, quant à l'administration et au placement de- actifs de la caisse d'assuranec-vie collective; i fiiirc un appel d'olfres à au moins deux compagnies d'assurance-vie relativement au régime d'assurance-vie collective visé par les présentes, quant A l'assurance, l'administration et au placement des actifs dudit régime.rf) demander, s'il y a lieu, l'avis de techniciens en fiducie, en placement, en assurance-vie collective, en droit de fiducie ou d'assurance-vie et autres matières, selon le cas; e) étudier les soumissions reçues.Si elles sont jugées inacceptables, faire un nouvel appel d'offres; ' désigner la ou les compagnies de fidéicommis ou la ou les compagnies d'assurance-vie, avec qui le comité paritaire doit signer le contrat de fiducie ou le contrat de retraite, selon le cas, OU le contrat d'assurance-vie collective; 37.00 Responsibility with Regard to Documents 37.01 The social security committee and each of its representatives are fully protected when acting upon a document or certificate believed by them to be authentic, signed and presented by the proper person(s).They shall be under no obligation to investigate or inquire into any statement contained in any such document but may accept the same as conclusive evidence of the truth and accuracy of the statements therein contained.38.00 Responsibility with Regard to Advisers 38.01 The social security committee may from time to time consult knowledgeable advisers.Representatives are fully protected when acting in accordance with or contrary to the advice of such advisers.Division 10 Duties and Powers of the Social Security Committee 39.00 General Administration 39.01 The social security committee shall see to the administration and proper operation of the retirement annuity plan, the group life insurance plan, the retirement fund and the group life-insurance fund.40.00 Duties of the Social Security Committee 40.01 The social security committee shall: (a) receive from the Parity Committee the amount of assessments and remit them, as herein provided for, to the retirement fund and to the group life-insurance fund respectively; (6) publish for and distribute to employees pamphlets explaining the main provisions of the social security plan with an exposé of their rights and duties together with any other information requested by the Quebec Pension Board.41.00 Contracts or Agreements 41.01 When entering into contracts, the social security committee shall: (a) ask at least two trust companies and two life insurance companies for tenders respecting the retirement annuity plan herein provided for, as regards the administration of such plan and the investment of the assets of the retirement fund; (6) ask at least two trust companies for tenders respecting the group life insurance plan herein provided for, as regards the administration and investment of the assets of the group life insurance fund; (c) ask at least two life insurance companies for tenders respecting the group life insurance plan herein provided for, as regards the insurance, administration and investment of the assets of the said plan; (d) seek, if need l>e, the advice of trust, investment, group life insurance, trust or life insurance law technicians or others, as the case may be; (e) study the tenders received.Should they he considered as inacceptable, make a new call for tenders; (/) appoint the trust company or companies or the life insurance company or companies with which the Parity Committee is to sign the trust contract or the retirement annuity contract, as the case may be, or the group life insurance contract; 3382 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1068, 100' année, n° 25 g) transmettre au comité paritaire l'original et trois copies de tout contrat de rentes «le retraite, de tout contrat de fiducie et dc tout contrat d'assurance-vie collective pour fins de signature.Une copie attestée vraie par les parties contractantes, de tout contrat ou renouvellement de contrat visé ci-avant doit être déposée sans délai chez le ministre du Travail et.respectivement, à la Régie des rentes du Québec, chez l'Inspecteur des compagnies en fidéicommis ou au bureuu du Surintendant des assurances.Après étude, les recommandations du ministère du Travail, de la Régie des rentes du Quél>cc, de l'Inspecteur des compagnies de fidéicommis ou du Surintendant des assurances doivent faire l'objet dc modifications à tout contrat ainsi visé.42.00 Renouvellement des contrats 42.01 Lorsqu'il s'agit dc renouveler le ou les contrats de fiducie ou contrats dc rente de retraite, ou le contrat d'assurance-vie collective, le comité de sécurité sociale détermine tout contrat de fiducie ou contrat de rente de retraite, selon le cas.ou tout contrat d'assurance-vie collective que le comité paritaire doit signer et ce.sans être obligé de suivre la procédure décrite à l'article 41.00 de la section 10 du présent titre 43.00 Suririllnnre dc la Régie des rentes et du Surintendant des Assurances 43.01 La Régie des rentes du Quéliec exerce une surveillance générale de la caisse dc retraite.La Régie des rentes du Québec, ou son représentant, a droit de vérifier en tout temps les livres, comptes et archives du comité dc sécurité sociale quant à la caisse dc retraite et, à cette fin.le comité paritaire le comité de sécurité sociale et leurs salariés doivent lui donner accès à leurs livres, comptes et archives et lui fournir tout renseignement qu'elle requiert.43.02 Chaque nnnéc.et chaque fois que la Régie des rentes il u Québec le requiert, le comité de sécurité sociale doit lui faire rapp>rt.43.03 Le Surintendant des Assurances exerce une surveillance générale de la caisse d'assurance-vic collective I,c Surintendant des Assurances ou son représentant a droit de vérifier en tout temps, les livres, comptes et archives du comité dc sécurité sociale quant à la caisse d'assurance-vie collectives et, à cette fin, le comité paritaire, le comité de sécurité sociale et leurs salariés doivent lui donner accès à leurs livres, comptes et archives et lui fournir tout renseignement qu'il requiert.43.04 Chaque année, et chaque fois que le Surintendant des Assurances le requiert, le comité dc sécurité sociale doit lui faire rapport.44.00 Pouvoirs du comité dc sécurité sociale 44.01 Le comité dc sécurité sociale a le pouvoir: a) de déterminer d'une façon finale les droits de tout salarié, ancien salarié ou retraité et dc tout bénéficiaire à des prestations comme participant au régime de rente de retraite et au régime d'assurance-vic collective; b) de déterminer la forme et les normes de tout contrat de fiducie ou contrat dc rente dc retraite, selon le cas, et dc déterminer la forme et les termes dc tout contrat d'assurance-vie collective de façon à assurer la réalisation du régime île rente de retraite et du régime d'assurance-vie collective; c) de passer tout contrat et entente en vue de mener a bonne fin les termes des Sections 11, 12 et 13 du présent titre, et pour la bonne marche (g) forward the original and three copies of any retirement annuity contract, trust contract and group life insurance contract to the Parity Committee for signing.A true copy, certified by contracting parties, of any of the abovemcn.tioned contracts or renewal of same shall lie immediately filed with the Minister of Labour, the Quéliec Pension Board, the Inspector of Trust Companies or the office of the Superintendent of Insurance.After study, the recommendations of the Department of Laliour, of the Québec Pension Board, of the Inspector of Trust Companies or of the Superintendent of Insurance shall be the object of amendment- to any contract herein referred to.42.00 Contract Renewal 42.01 At renewal time of the trust contract retirement annuity contracts) or group life-insurance contract(s), the social security com-mittee shall determine any trust contract, retirement annuity contract or group life-insurance contract that the Parity Committee should sign, without having to follow the procedure set forth in section 41.00, Division 10, Part Five.43.00 Supervision of the Quebec Pension Board and of the Superintendent of Insurance 43.01 The Québec Pension Board exercises a general supervision over the retirement fund.The Québec Pension Board, or its representative, may at all times check the books, accounts ami records kept by the social security committee relative to the retirement fund.For this purpose, the Parity Committee, the social security committee and their employees sliall give him OCCen to their books, accounts anil records and shall supply him with any information he may require.43.02 Every year and every time the Québec Pension Board so requests, the social security committee shall report to it.43.03 The Superintendent of Insurance exercises a general supervision over the group life-insurance fund.The Superintendent of Insurance, or his representative, may at all times check the liooks, accounts and records kept by the social security committee relative to the group life insurance fund.For this purpose, the social security committee, the Joint Committee and their employees shall give him access to their hooks, accounts and records and shall supply him with any information he may require.43.04 Every year and every time the Superintendent of Insurance so requests, the social security committee shall report to him.44.00 Pouxrs of the Social Security Committee 44.01 The social security committee has the power to: (a) determine finally the rights of any employee, former employee, pensioner and bciiefi-nary to benefits as participant to the retirement annuity plan or group life-insurance plan; (i) determine the form and standards of any trust or retirement annuity contract and determine the form and terms of any group life insurance contract in order to ensure the implementation of the retirement annuity and group life insurance plans; (c) enter into any contract and agreement for the purpose of carrying out the provisions of Divisions 11, 12 and 13 of this Part and for the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 am égarante iis d'admissibilité de l'alinéa «a» du paragraphe 47.01 de la section 11 du présent titre, ou les conditions d'admissibilité dc l'alinéa « a > du paragraphe 47.02 de la section 11 du présent titre.49.02 Aux fins d'application du paragraphe 19.01 de la section U du présent titre, aucun salarié n'est considéré comme ayant cessé d'être Un salarié avant l'expiration de deux (2) années consécutives après sa dernière cotisation au fonds de sécurité sociale.49.03 Contribution de salarié âgé de soixante-cinq (65) ans et plus: Toute contribution versée en vertu d'heures de travail effectuées par un -alarié qui a atteint l'âge de soixante-cinq (65) \u2022¦us devient remboursable à tel salarié à la fin de chaque année civile pour laquelle elle a été Versée ou au décès du salarié si cette date survient avant, sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 49.01 et 49.02 de la section 11 du présent titre.48.03 Claimant's Bight: The social security committee luis the right to withhold payment of any refund payable as a result of the death of an employee, former employee or pensioner, to any pi-.-: claiming such payment until the claimant's right to such payment has been established to the satisfaction of the social security committee.49.00 Non-Qualifying Benefits 49.01 Entitlement and Amount of Benefits: (a) If an employee ceases to he an employee before having contributed for ten (10) years to this plan and In-fore having reached his forty-fifth (45th) birthday, he is entitled to apply for refund of his accumulated employee contributions.Acceptiug such refund equals a total renunciation of all rights and privileges an employee may be entitled to.(b) If an employee ceases to he an employee after having contributed for ten (10) years to tins plan but before having reached his forty-fifth (45th) birthday, he may, but is not compelled to, apply to the social security committee for refund of his accumulated employee contributions.This should Ik- done lieforc reaching his forty-fifth (45th) birthday.Nevertheless, he may choose a retirement annuity upon his meeting the requirements listed in paragraph \"a\", subsection 47.01, Division 11, Part Five.(c) If an employee ceases to be an employee after having contributed for ten (10) years to this plan and after having reached his forty-fifth (45th) liirl hday.he is not.entitled to withdraw his accumulated employee contributions, but he is entitled to the retirement annuity stipulated in paragraph \"b\", subsection 47.01, Division 11, Part Vive, whenever he meets the requirements listed as nos.1 and 3 in paragraph \"o\", subsection 17.01.Division II, Pari Five or I he requirements of paragraph \"a\", subsection 47.02, Division 11, Part Five.However, such employee may apply to the social security committee for a partial payment of a deferred retirement annuity equal to twenty-five (25%) of the actuarial value of the retirement benefit provided for in paragraph \"b\".subsection 47.01, Division 11.Part Five, except that the maximum payment will consist of his accumulated employee contributions.The balance of the deferred annuity may lie paid upon his meeting the eligibility requirements of paragraph \"a\", subsection 47.01, Division 11.Part Five or the eligibility requirements set forth in paragraph \"a\", subsection 47.02, Division 11, Part Five.49.02 For the purjioses of enforcing subsection 49.01, Division 11, Part Five, no employee will lie considered as having ceased to be an employee until the expiration of two consecutive years after his last contribution to the social security fund.49.03 Contribution of Employee Age sixty-fire (65) and (her: Any contribution, paid by an employee who lias reached his sixty-fifth (65th) birthday, in respect of hours of work -ball lie refunded to such employee at the end of each calendar year for which they have been paid or on the employee's death, whichever should come first, subject to the restrictions set forth in subsections 49.01 and 49.02, Division 11, Part Five. 3388 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 19G8, 100' année, n\" 26 50.00 Déclarations 50.01 Durée du régime de renie de retraite: Le régime de rente de retraite demeure cn vigueur jusqu'à l'expiration du présent décret et peut être renouvelé dc temps à autre par tout décret subséquent.50.02 Échéance du régime de rente de retraite: Attendu que les dispositions du régime de sécurité sociale sont une extension des conventions collectives dc travail intervenues entre l'Association des Constructeurs dc Saint-Hyacinthe, Bagot, Kouville; l'Association des Constructeurs de la Vallée du Richelieu Inc.; l'Association des Entrepreneurs en Construction de Brome, Missisquoi, Shefford (district de Redford); et, le Syndicat national «les métiers de la Construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.); le Syndicat catholique national de la Construction dc Saint-Jean Inc.(C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers de la Construction de Granby Inc.(C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers du Bâtiment dc Cowansville Inc.(C.S.N.); la fédération nationale des Syndicats du Bâtiment et du Rois Inc.(F.N.S.R.R.), et que l'expiration du décret placerait les signataires de ladite convention dans une situation différente de celle des assujettis par décret, les parties conviennent donc que, si le décret n'était pas renouvelé, toutes les dispositions du régime de sécurité sociale relatives au régime de rente de retraite contenues au présent titre et faisant partie de ladite convention collective de travail seraient immédiatement et en même temps échues.Le comité dc sécurité sociale devrait alors procéder conformément au [wiragraphe 50.03 au présent article.50.03 Effet de l'échéance du régime dc rente dc retraite: Si le présent régime dc rente de retraite n'était pas renouvelé tel que mentionné précédemment, alors les contributions audit régime dc rente dc retraite cesseraient et ledit régime deviendrait échu un (1) an après son non-renouvellement.Dans un tel cas, le comité de sécurité sociale déterminera, sous réserve dc l'article 40 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes, dc façon définitive, la quotc-pnrt à laquelle chaque salarié, ancien salarié et retraité a droit cn vertu dc la présente section.Le comité dc sécurité sociale prévoira alors le paiement dc la totalité dc la caisse dc retraite, y inclus tout surplus d'argent, à tous tels salariés, anciens salariés et retraités.En conséquence, la caisse sera employée pour fournir, premièrement, à chaque retraité, la continuation «l'une rente de retraite d'un montant au moins égal à celui auquel il a droit en vertu dc la présente section et, deuxièmement, à chaque autre salarié ou ancien salarié qui a un intérêt quelconque dans la caisse, une partie équitable de la caisse, soit sous forme d'une rente de retraite si possible, soit cn argent comptant.Section 12 Régime d'assurance-vic collective 51.00 Caisse d'assurance-vie collective de l'Industrie de la Construction des régions dc Saint-Hyacinthe, Saint-Jean et Granby 51.01 But: La caisse d'assurance-vie collective existe dans le but unique et exclusif de pourvoir à des prestations d'assurance au décès pour les salariés.Le comité dc sécurité sociale doit souscrire une police d'assurance-vic collective avec une compagnie d'assuranec-vic afin de prévoir le versement des prestations dc décès mentionnées à la présente section.50.00 Statements 50.01 Term of the Retirement Annuity Plan: The retirement annuity plan shall remain in force until the expiration of this decree ami may lie renewed from time to time by any subsequent decree.50.02 Expiration of the Retirement Annuity Plan: Whereas the provisions of the social security plan are but as extension of the collective labour agreements entered into between l'Association des Constructeurs dc Saint'-Hyacinthe, Bagot, Rnurille; l'Association des Constructeurs de la Vallée du Richelieu Inc.; l'Association des Entrepreneurs en Construction de Brime, Missi*.quoi, Shefford (district de Bedford) and le Syndicat national des métiers de la Construction dc Saint-Hyacinthe (C.S.N.); le Syndicat catholique national de la Construction de Saint-lean Inc.(t'.S.N.); le Syndicat national et catholique if» .Jêtiers de la Construction de Granby Inc.{C.S.N.: le Syndicat national et catholique des métiers e used to provide; first, that every pensioner shall continue to receive at least the pension to which he is entitled under (Indivision and, second that every other employ* i or former employee who 1ms any interest in the fund shall lie entitled to an equitable portion of the fund, either in the form of a retirement benefit, if possible, or in cash.Division 12 Group Life Insurance Plan 51.00 Group Life Insurance Fund of the Construction Industry of the St.Hyacinthe, St.Jean.Granby Regions 51.01 Purpose: The group life insurance fund exists for the sole purpose of providing death insurance licncfils for employees.The social security committee shall take a group life-insurance policy with a life insurance company that will provide for the payment of the death benefits mentioned in tliis division. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968.Vol.100.No.25 3880 31.02 Composition: La caisse d'assurance-vie collective consiste en tous les montants dc cotisations versées cn conformité dc l'article 12.00 de la section 3 du présent titre et en les gains et profits réalisés avec ceux-ci en les investissements et réalisations desdits investissements et en tous les gains et profits de ces investissements.Lee placements de cette caisse doivent être faits conformément aux règlements édictés par la Régie des rentes du Québec et le Surintendant de- Assurances du Québec.52.00 Prestations de décès 52.01 Admissibilité ù une période d'assurance: a) Est admissible à une période d'assurance: 1.Tout salarié qui a accumulé au fonds de sécurité sociale un montant minimal dc quinze dollars ($15) de cotisations de salarié au cours de trois (3) mois civils consécutifs; 2.ou tout salarié qui a accumulé au fonds dc sécurité-sociale un montant minimal dc trente dollars ($30) de cotisations de salarié au cours dc six (0) mois civils consécutifs; 3.ou tout salarié qui a accumulé au fonds dc sécurité sociale un montant minimal de soixante dollars ($00) de cotisations dc salarié au cours dc douze (12) mois civils consécutifs./;) Aux fins des présentes, les cotisations de salariés doivent toujours être calculées pour la période réelle dc travail pour laquelle elles ont été déduites; e) Lorsque des contributions de salariés ont été déduites par l'employeur et que ce dernier a négligé de les remettre au comité paritaire, le comité île sécurité sociale peut, pour établir l'admissibilité d'un salarié ou ancien salarié à une |x;riode d'assurance, tenir compte des contributions déduites mais non remises si ledit comité reçoit des preuves suflisantes et satisfaisantes que l'employeur a déduit ces sommes d'argent dc la paie du salarié et que le fait que lesditcs sommes d'argent n'ont pas été remises au comité paritaire n'est aucunement imputable audit salarié ou ancien salarié.52.02 Période d'assurance: Une période d'assurance consiste en trois (3) mois civils consécutifs pendant lesquels la vie d'un salarié est assurée, la période d'assurance débute le premier jour du mois où un salarié est admissible conformément a l'une ou l'autre des conditions définies au paragraphe 52.01 de la section 12 du présent titre.52.03 Salarié invalide: a) Conditions d'admissibilité: Est considéré comme un salarié invalide un salarié qui remplit toutes et cliacune des conditions suivantes: 1.être frappé d'invalidité totale avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans; 2.déposer au comité de sécurité sociale une d aliunde écrite aux fins d'être considéré comme un salarié invalide; 3.avoir été un salarié admissible à une période d'assurance à une certaine époque pendant les neuf (9) mois précédant immédiatement la date de réception de sa demande écrite par le comité de sécurité sociale; cependant, le comité de sécu-i ité sociale peut, dans certains cas, étudier selon ses mérites, mie demande faite après plus de neuf (.9) mois; 4.avoir été continuellement invalide depuis I époque où il était un salarié admissible aune ixriodc d'assurance; 51.02 Contents: The group life insurance fund consists of all assessment amounts paid in compliance with sections 12.00, Division 3, Part Five, of all earnings and profits thereon, of all investments and proceeds on such investments and of all proceeds and profits on such investments.This fund is to be invested in accordance with the regulations enacted by the Quéliec Pension Board and the Québec Superintendent of Insurance.52.00 Death Benefits 52.01 Eligibility to a Term of Insurance: (a) The following are eligible to a term of insurance: 1.any employee who has accumulated in the social security fund a minimum of fifteen dollars ($15) in employee contributions during three (3) consecutive calendar months; or 2.any employee who has accumulated in the social security fund a minimum of thirty dollars ($30) in employee contributions during six (6) consecutive calendar montlis; or 3.any employee who has accumulated in the social security fund a minimum of sixty dollars ($60) in employee contributions during twelve (12) consecutive calendar months.(6) For the purposes hereof, employee contributions shall always lie computed for an actual working period for which they have been deducted.(c) When employee contributions have been deducted by the employer and the latter has neglected to forward litem to the Parity Committee, the social security committee may, in order to determine an employee's or former employee's entitlement to a term of insurance, take into account the contributions deducted but not forwarded, provided the said committee obtains sufficient and satisfactory proof that the employer has deducted such amounts from the employee's pay cheque and provided that the non-forwarding of such amounts to the Parity Committee not be due to any fault of the employee or former employee.52.02 Term of Insurance: A term of insurance consists of three (3) consecutive calendar months during which an employee's life is insured.The term of insurance begins on the first of the month the employee becomes eligible in accordance with either of the conditions set forth in subsection 52.01, Division 12, Part Five.52.03 Disabled Employee: (a) Eligibility Requirements: An employee who meets all and each of the following requirements is considered as a disabled employee: 1.become totally disabled before attaining age of sixty-five (65) ; 2.file with the social security committee a formal application to be considered as a disabled employee; 3.have been an employee eligible to a term of insurance at some time during the nine-month period preceding the date of receipt of lus formal application by the social security committee.However, the social security committee may, in special cases, judge the merits of or study an application that is more than nine (9) months old; 4.have been continuously disabled since he last was an employee eligible to a term of insurance; 8890 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 19C8, 100- année, n\" 25 5.faire preuve de son Age à lu satisfaction «lu comité de sécurité sociale; G.faire la preuve «le son invalidité totale et, à cet effet, se soumettre à un ou plusieurs examens médicaux «levant un ou plusieurs médecins désignés par le comité dc sécurité sociale ou son représentant; 7.ne pas être un retraité.b) Invalidité totale: L'invalidité totale n'inclut DM une invalidité résultant d'activité criminelle, d'ivresse habituelle, de mutilation volontaire, dc l'usage habituel dc narcotique ou de service militaire.c) Continuation dc T invalidité: l'n salarié est considéré invalide ]>enilunt la continuation dc son invalidité |x>ur une période d'une (1) année suivant ladatc d'approbation de sa demande par le comité de sécurité sociale.d) Par la suite, le salarié continue d'être un salarié invalide |>cndant la continuation de son invalidité totale pour des périodes subséquentes d'une (1) année chacune eu établissant un début dc chaque période la eont inuation de son invalidité tota'e à la satisfaction du comité «le sécurité sociale, e) Cessation dc Tinralidité: l'n salarié cesse d'être un salarié invalide au moment où l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise: 1.lorsqu'il cesse d'être totalement invalide ou ne réussit pas à prouver à la satisfaction du comité «le sécurité sociale la continuation de son invalidité totale; 2.lorsqu'il se livre à un emploi rémunéré autre qu'un emploi exercé dans un but de réadaption et qui ne comporte qu'un salaire minimal; 3.lors«iu'il devient un retraité.Tout salarié qui devient retraite et qui a droit à la prestation de décès prévue à l'alinéa « e » du paragraphe 52.05 de la section 12 du présent titre, ne peut par la suite avoir droit à la prestation de décès à titre de salarié invalide.52.04 Betraité admissible: a) l'n retraité admissible est celui qui immédiatement avant d'avoir droit à des prestations dc rente de retraite, est soit un salarié admissible A une période «l'assurance conformément au paragraphe 52.01 de la section 12 du présent titre, soit un salarié invalide conformément au l>aragraphc 52.03 «le la section 12 du présent titre.b) Tout retraité comme tel cesse d'être un salarié admissible à une |>ériode «l'assurance.c) Tout salarié qui devient retraité alors qu'il a droit à une prestation de décès conformément à l'alinéa « c » du paragraphe 52.05 de la section 12 du présent titre, ne peut par la suite devenir un salarié admissible à une période d'assurance.52.05 Prestations de décès: Jusqu'à décision contraire, les prestations «le décès visées par la présente section sont les suivantes: a) une prestation dc décès de «leux mille dollars (82.000) lorsque le salarié admissible ù une période d'assurance décède avant d'avoir atteint l'Age dc soixante-cinq (65) ans; b) une prestation dc décès dc cinq cents dollars ($500) lorsque le salarié admissible à une période d'assurance décède à l'Age dc soixante-cinq (65) ans et plus; c) une prestation de décès de deux mille dollars ($2,000) lorsque le salarié invalide décède avant d'avoir atteint l'Age dc soixante-cinq (65) ans; 5.prove his age to the satisfaction of the social security committee; 6.establish his total disability and in so doing, submit to a physical examination or examinations by a doctor or doctors chosen by the social security committee or its representative; 7.not l>c a pensioner.(b) Total Disability: Total disability shall not include disability suffered as a result of criminal activity, habitual drunkenness, self-inflicted in.jury, military service or addiction to narcotics.(e) Continuance of Disability: An employee shall Ik: considered disabled during the e.- h nuance of his disability for a period of one |11 year allowing the date of approval of his application by the social security committee (e a disabled employee whenever any of the following conditions is met; 1.he ceases to Ik- totally disabled or fails lo prove the continuance of his total disability to the satisfaction of the social security committee; 2.he engages in gainful employment other than for purposes of rehabilitation on a nominal wage basis; 3.he liecomcs a pensioner.Any employee w ho becomes a pensioner and is entitled to death benefits as provided for in paragraph \"c\", subsection 52.05.Division 12.Part Five, cannot become entitled to a death benefit as a disabled employee 52.04 Eligible Pensioner: (a) An eligible pensioner is one who, immediately l>eforc Incoming entitled to retirement annuity benefits, is cither an employee eligible to a term of insurance as set forth in subsection 52.01.Division 12.Part Five, or is a disabled employee as set forth in subsection 52.03, Division 12, Part Five (b) Every jiensioner as such ceases to be an employee eligible to a term of insurance.(e) Every employee wdio becomes a pensioner when being entitled to a death benefit in pursuance of paragraph \"c\", subsection 52.0.).Division 12, Part Five, cannot thereafter become an employee eligible to a term of insurance 52.05 Death Benefits: Until otherwise deter-mined, death benefits referred to in tliis division are payable as follows: (a) two thousand dollars ($2,000) when an employee who is eligible for a term of insurance dies l>efore reaching age sixty-five (65) ; (b) five hundred dollars ($500) when an employee who is eligible for a term of insurance passes away at age sixty-five (65) or more; (c) two thousand dollars ($2,000) when a disabled employee dies before reaching age sixty-five (65); QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3391 rt avec la subsistance, les .soins médicaux, les frais de dernière maladie.les frais funéraires et d'enterre-ment fournis au salarié, ancien salarié ou retraité, ou qui réclame une partie de la succession en rapport avec ces frais.53.03 Paiement différé: Le comité de sécurité sociale a droit dc différer le piiemenl île toute prestation de décès payable en vertu dc la présente section jusqu'à ce que le réclamant ait établi sou droit de recevoir paiement à la satisfaction du comité de sécurité sociale.53.01 Réclamation non avenue: Aucun salarié, ancien salarié ou retraité n'a droit de réclamer un montant d'argent au lieu des prestations dc décès prévues par la présente section.51.00 Déclaration 51.01 Durée du régime d'assurance-vie collective: I.c régime d'assurance-vie collective demeure i u vigueur jusqu'à l'expiration du présent décret et peut être renouvelé «le temps à autre par tout décret subséquent.51.02 Échéance du régime d'assuraucc-tie collec-lire: Attendu que les dispositions du régime de sécurité sociale sont une extension de la convention collective de travail intervenue entre l'Association des Constructeurs dc Saint-Hyacinthe, Magot, ltouville; l'Assocation des Constructeurs de la Vallée du Richelieu Inc.; l'Association des l'ntrepreneurs en Construction de Brome, Missisquoi, Shefford (District de Bedford); et le Syndicat national des métiers dc la Construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.); Le Syndicat catholique national de lu Construction de Saint-Jean Inc., (C.S.N.); Le Syndicat national et Catholique des métiers «le la Construction de Granby Inc.(C.S.N.); Le Syndicat national et catholique des métiers du Bâtiment de Cowansville Inc.(C.S.N.); La Fédération Nationale des Syndicats du Bâtiment et du Bois Inc.(F.N.S.B.B.); et que l'expiration du décret placerait les signatures de ladite convention dans une situation différente dc celle des assujettis par décret, les lnirtics conviennent donc que, si le décret n'était pis renouvelé, les dispositions du régime de sécurité sociale relatives au régime d'assurance-vie collective contenues au présent titre et faisant partie de ladite convention collective de travail seraient immédiatement et en même temps échues.Le comité dc sécurité sociale devrait alors procéder conformément au paragraphe 54.03 du présent titre.51.03 Effet de l'échéance du régime d'assurance-vie collective: Si le présent régime d'assurance-vic collective n'était pas renouvelé tel que mentionné (d) five hundred dollars ($500) when a disabled employee passes away at age sixty-five (05) or more; (e) five hundred dollars ($500) when an eligible pensioner dies.53.00 Payment of Death Benefits 53.01 Payment to (he Beneficiary: Any death benefit payable under this division on the death of an employee, former employer or pensioner shall be paid to the beneficiary of such employee, former employee or pensioner upon making formal application to the social security committee.53.02 Payment to Any Designated Person: However, the social security committee has the authority to direct that payment be made to anyone related by blood or marriage to the employee, former employee or «Irceased pensioner or to any other person who, in the social security committee's opinion, is legally entitled to payment because of having incurred expenses for the upkeep, medical expenses, last illness, burial or funeral of the deceased, or who claims part of the estate in respect of such expenses.53.03 Deferred Payment: The social security committee hns the right to defer the payment of any death benefit payable hereunder until the claimant has established his right to payment to the satisfaction of the social security committee.53.04 Illegitimate Claim: No employee, former employee or pensioner may claim an amount of money in lieu of the death benefits provided for herein.54.00 Statements 54.01 Term of the Group Life Insurance Plan: The group life insurance plan shall remain in force until the expiration of this decree and may be renewed from time to time by any subsequent decree.54.02 Expiration of the Group Life Insurance Plan: Whereas the provisions of the social security plan are but an extension of the collective labour agreement entered into between l'Association des Constructeurs de Saint-Hyacinthe, Bagot, Bouville: l'Association des Constructeurs de la l'allée du Richelieu, Inc.; l'Association des Entrepreneurs en Construction de Brome, Missisquoi, Shefford (District de Bedford) and le Syndicat national des métiers de la Construction de Saint-Hyacinthe (C.S.N.); le Syndicat catholique national de la construction de Saint-Jean Inc., (C.S.N.); le Syndicat national et catliolique des métiers de la Construction de Granby (C.S.N.); le Syndicat national et catholique des métiers du Bâtiment de Cowansville Inc.(C.S.N.); la Fédération nationale des Syndicats du Bâtiment et du Bois Inc.(F.N.S.B.B.); and the expiration of the decree would put the signatories of the said agreement in a position different from that of those subject to the decree, the contracting parties therefore agree that, if the decree was not renewed, all the provisions of the social security plan dealing with the group life insurance plan contained in this Port and being part of the said collective labour agreement, would at once and at the same time expire.The social security committee should then proceed in accordance with subsection 54.03 of this Part.54.03 Effects of Non-Renewal of the Group Life Insurance Plan: Should this group life insurance plan not be renewed as aforesaid, contributions 3392 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n' 25 précédemment, alors les contributions audit régime d'assurance-vie collective cesseraient et tout l'actif «le la caissse d'assurance-vic collective doit d'abord servir à la compagnie d'assurance-vic qui assume à ce moment le risque aux fins dc continuer cette assurance uu décès le plus longtemps [Kissible dans l'intérêt des vies assurées; après quoi, le régime d'assurance-vie collective sera expiré.Section 13 Administration de contributions et tenue de dossiers 55.00 Administration de contributions 55.01 Le comité de sécurité sociale peut accepter l'administration dc contributions d'employeurs et de salariés relatives à un fonds dc sécurité sociale pour des employeurs et salariés assujettis à un autre décret si une requête lui est présentée à cette fin et si les intéressés en conviennent préalablement par une convention écrite.55.02 Ladite convention doit prévoir que les disjMjsitions et stipulations du Titre Cinquième intitulé « Régime «le sécurité sociale » du décret de l'industrie de la construction des régions «le Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, G-ran by et ses modifications, ou tout autre décret qui le remplacerait, seront applicables mutatis mutandis.55.03 Une telle convention se limitera à l'industrie du bâtiment ou ù «les industries connexes ou à des industries dont le travail se fait cn partie à l'atelier et en jNirtîe sur le chantier.55.04 Une copie d'une telle convention doit êtra déposée chez le ministre «lu Travail et à la Régie des Rentes du QuébeCi 56.00 Tenue des dossiers 56.01 Le comité de sécurité sociale peut accepter la tenue «le dossiers relatifs à un régime de sécurité sociale pour des cmp!«>ycurs et «les salariés assujettis à un autre décret si une requête lui est présentée à cette fin et si les intéressés cn conviennent préalablement |»r une convention écrite.56.02 Une telle convention se limitera à l'industrie du bâtiment ou ù des industries connexes ou à des industries dont le travail se fait en partie à l'atelier et en partie sur le chantier.» Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 25016-o D.Tanouay.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1712 Quéljcc.le 6 juin 1908.Présent: Le Lieutenant-gouverneur cn conseil.Conckiinant l'abrogation du décret relatif aux photographes professionnels des Cantons dc l'Est.Il est onnoNXK, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: Que, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets «le convention collective (Statuts refondus du Québec.1964, cliapitre 143), le «lécret numéro 315 du 27 mars 1957.relatif aux photographes professionnels des Cantons de l'Est, soit abrogé à toute fin que de droit.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 25016-o D.Tanouay.to the said plan woulil cease and the entire assent of the group life insurance fund shall first lie used by the underwriting life insurance company for the purpose of continuing such death insurance as long as possible in the interest of the lives insured; thereafter, the group life-insurance plan would expire.Division 13 Administration of Assessments and Keeping of Records 55.00 Administration of Contributions 55.01 The social security committee may accept to administer the employer and employee assessments in respect of the social security fund for employers and employees subject to another decree, if a request to this effect is presented to it and if the interested parties previously sign a written agreement.55.02 The said agreement shall make certain that the provisions and stipulations of Part hive entitled \"Social Security Plan\" of the décrie respecting the Construction Industry in the St.Hyacinthe, St.Jean, Granby regions, as amended, or any other decree superseding it, shall be applicable mutatis mutandis.55.03 Such agreement will lie restricted to the building industry, to related industries or to industries whose work is carried out partly in the shop and partly on the construction site.55.04 A copy of such agreement shall be filed with the Minister of Laliour and Oie Québec Pension Board.56.00 Keeping of Records 56.01 The social security committee may accept to keep rear l'architecte sont des instruments de service pmr l'exécution de l'ouvrage et restent sa propriété, que l'ouvrage soit exécuté ou non.et Iarchitecte se réserve les droits d'auteur à leur égard; ils ne pourront servir à d'autres ouvrages, à moins que l'architecte n'ait donné son consentement et soit rémunéré à cet elfct conformément aux dispositions du présent tarif.4.Détermination des honoraires 4.1 Les deux principes suivants constituent conjointement la base rationnelle de la rémunération : \u20221.11 Le taux des honoraires varie en raison inverse de l'ini|>ortance du coût total de l'ouvrage.4.12 Le taux des honoraires s'accroît, à dépense égale, selon la nature des édifices, cn raison directe de la complexité de l'ouvrage, dc l'importance des études et recherches, des difficultés de réalisation, de la responsabilité engagée.4.2 Selon leur nature et leur complexité, les bâtiments sont classés en quatre (4) catégories établies ci-dessous, celle classification ne devant en aucun cas limiter ou accroître le champ de pratique de l'architecte défini par la loi.Les bâtiments qui n'apparaissent juts dans la nomenclature de chacune de ces catégories appir-ticimcnt à la catégorie à laquelle ils s'assimilent le plus.Advenant un changement substantiel dans le degré dc complexité de certains bâtiments ou travaux, leur classement dans les catégories établies peut être modifié conjointement par le client d'une part, et le conseil de l'Association des architectes d'autre part.Advenant un désaccord quant au classement d'un ouvrage en particulier, la question sera tranchée par un arbitrage entre le client et le conseil dc l'Association des architectes afin de décider du classement approprié en regard des catégories établies.1ère catégorie 4.201 bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles comportant de grands espaces vides; 4.202 grands garages ouverts; 4.203 hangars, entrepôts, écuries; 4.204 manèges; 4.205 hangars d'avion.2ème catégorie 4.210 maisons dc commerce; 4.211 bâtiments d'administration de caractère simple, y compris les hôtels de ville et palais de justice de caractère simple; cd for production, manufacturing, treatment or processing.3.Other contractual prorisions catering unfon tea circumstances during construction 3.1 If unforeseen, critical circumstance* ari-c when the project is under way.the architect may.following provisions specified in the contract » lieu applicable, order or have carried out on behalf of the client and as the letter's agent, urgent work considered necessary or advisable in the client's interest or for public protection.The co-l of such work then becomes part of the \"total cost of the project\".Ownership of documents 3.2 All drawings, scale models.Specification! and documents prepared by the architect are instruments for use in carrying out a project ami remain his property whether the structure i-erected or not.The architect retains his vested interest in them and they may not be Used for any other project unless he gives his consent and is piid uccording to the conditions contained in the present Hate structure 4.Determination offres 4.1 The following two principles shall jointly constitute the basis of payment.4.11 Fee rates shall vary inversely with the total cost of the project.4.12 Expenses remaining equal, fee rates -.ball increase according to types of buildings and in direct ratio to the complexity of structures, extent of studies and research, the difficulties in (allying out the project und assumed liabilities.4.2 Provided this classification shall in no way restrict or broaden the scope of architectural practice as defined under the act, buildings shall fall into one of the four (4) categories Ixdow according to their type and complexity, buildings not listed in any of these categories shall la-long in the category which they most closely resemble.In the event of substantia] change in degree (>' complexity of certain buildings or works, their classification in the established categories may lie modified jointly by the client and the Council «>f the Association of Architects.Should disagreement arise on the classification of a given proji ct the matter shall be settled through negotiations between the client and the Council of the Association so as to arrive at proper classification with regard to the established categories.1st category 4.201 Industrial, commercial or agricultural buildings including large vacant space*.4.202 Large open garages.4.203 Sheds, warehouses, stables.4.204 Drill balls.4.205 Aircraft hangars.2nd category 4.210 Commercial establishments.4.211 Administration buildings, including city ball- and court houses, of simple const ruction. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, Xo.25 3397 4.21.' écoles primaires; 4.213 établissements de bain; 4.211 motels et marinas; 4.21\"i casernes; 4.2b' gares ferroviaires ou routières de peu d'importance; 4.217 garages d'entretien et dc réparation; 1218 magasins de distribution; 4.219 immeubles d'appartements ou maisons multifamiliales ou maisons en rangées; 1.220 édifices à bureaux; 4.221 bâtiments militaires; 4.222 |wstcs de pompiers et dc jiolice; 1223 foyers sociaux, réfectoires, colonies dc vacances; 4.221 abattoirs; 1225 les bâtiments industriels abritant des ouvrages de génie mécanique tel que les mécaniques d'épuration des eaux, les mécaniques de sédimentation et de pompage et les centrales thermiques; 4.220 établissements de pompes funèbres et crématoires; 4.227 garages fermes; 4.22s stades; 1229 salles de gymnastiques; 4.230 établissements pénitentiaires; 1231 |>atinoires intérieures et nrénas.Simt catégorie 1240 bâtiments d'administration; 4.211 banques; 4 212 édifices de culte; 1243 studios, bâtiments abritant les émetteurs de radio et de télévision et les centrales téléphoniques; 1.211 musées, bibliothèques; 4.2l.'i théâtres, salles de concerts, cinémas, salles de spectacles, casinos, clubs; 4.210 laboratoires, hôpitaux, cliniques, orphelinats, refuges pour vieillards; 4.217 hotels, restaurants; 1248 gares maritimes, fluviales, routières; aérogares, gares ferroviaires; 4.219 maisons familiales, villas, résidences et hotels particuliers; 4.250 établissements d'enseignement supérieur, universitaire ou spécialisé; 1251 écoles normales, secondaires ou polyvalentes.Vme catégorie: 1.20(1 les travaux de décoration ou d'aménagement de pièces d'habitation, dc stands d'exposition; 4.201 les jardins publics, promenades, fontaines; 1282 les monuments commémoratifs et funéraires; 1-20 I tous travaux dc transformation dc quelque nature qu'ils soient, s'ils engagent la responsabilité de l'architecte dans une mesure plus importante que la valeur marchande des ouvrages exécutés; 4 201 ouvrages de restauration de monuments historiques, bâtiments, monuments ou intérieurs historiques; L205 pavillons d'exposition; 4360 ameublement.Tableau des honoraires 1.3 Pour chacune de ces catégories dc bâtiments, les honoraires sont établis proportionnellement au coût total dc l'ouvrage, à cette fin divisé en dix tranches, le tout selon le tableau suivant.4.212 Elemcntarv schools.4.213 bathing establishments.4.214 Motels and marinas, 4.215 barracks.4.210 Small railway or bus stations.4.217 Maintenance and repair garages.4.218 Shops.4.219 Apartment buildings, multiple-family dwellings or row housing.4.220 Office buildings.4.221 Military structures.4.222 Pire and police stations.4.223 Recreation centres, dining halls, summer camps for youngsters.1.224 Slaughter-house-.4.225 Industrial buildings housing mechanical engineering works such as water filtration, sedimentation and pumping equipment or heating plants.4.220 Funeral homes and crematoriums.4.227 Enclosed garages.4.228 Stadiums.4.229 Gymnasiums.4.230 Penal institutions.4.231 Indoor skating rinks and arenas.Ml category 4.240 Administration buildings.4.241 Hanks.4.242 Places of worship.4.243 Studios, buildings housing radio and television transmitting equipment and telephone exchanges.4.244 Museums, libraries.4.245 Theatres, concert halls, movie-houses, entertainment balls, casinos, clubs.4.240 Laboratories, hospitals, clinics, orphanages, homes for the aged.4.247 Hotels, restaurants.4.248 Harbour, river, road and railway stations, airports.4.249 Family dwellings, villas, residences and private mansions.4.250 Colleges or specialised schools, universities.4.251 Normal, secondary or polyvalent schools.',lh category 4.200 Interior decoration of living quarters and exhibition stands.4.201 Public gardens, drives, fountains.4.262 Commémorai ive and funeral monuments.4.263 Any transformation work whatever involving the architect's responsibility to a greater extent than the market value of structures erected.4.264 Restoration of historic monuments, buildings, or interiors.4.265 Exhibition pavilions.4.260 Furnishings.Schedule of fees 4.3 For each category, fees shall lie set in proportion to the total project cost which, for this purpose.Is broken up into ten divisions according to the following schedule. Tranches\tCoût total de l'ouvbage\tHonoraires Fees\t\t\t Division\tTotal cost of the project\t1ère catégorie 1st category\t2e catégorie 2nd category\tSe catégorie 3rd category\t4e catégorie 4th category 1ère 1st\tjusqu'à \u2014 up to S 62,500\t4.5%\t5.5%\t6.5%\t10% 2e 2nd\tde \u2014from $ 62,500 à \u2014 to 8 125,000\t$ 2,812.50 plus 4.25% *\t$ 3,437.50 plus 5% *\t$ 4,062.50 plus 6% *\t$ 6,250.00 plus 9% * 3e 3rd\tde\u2014from $ 125,000 à \u2014to S 250,000\t$ 5,468.75 plus 4% *\t$ 6,562.50 plus 4.5% *\t$ 7,812.50 plus 5.5%*\t$ 11,875.00 plus 8% * 4e 4th\tde \u2014from S 250,000 à \u2014to S 500,000\tS 10,468.75 plus 3.75% *\t$ 12,187.50 plus 4% *\t$ 14,687.50 plus 5% \u2022\t$ 21,875.00 plus 7.25% * 5e 5th\tde \u2014 from S 500,000 à \u2014to S 1,000,000\t$ 19,843.75 plus 3.5% *\t$ 22,187.50 plus 3.9% *\t$ 27,187.50 plus 4.7% *\t$ 40,000.00 plus 6.6% * 6e 6U1\tde \u2014from S 1,000,000 à \u2014to $ 2,000,000\t$ 37,343.75 plus 3.25% \u2022\t$ 41,687.50 plus 3.8% *\t$ 50,687.50 plus 4.5% *\t$ 72,500.00 plus 6% * 7e 7th\tde \u2014from S 2,000,000 à \u2014 to $ 4,000,000\t$ 69,843.75 plus 3% *\t$ 79,687.50 plus 3.7% *\t$ 95,687.50 plus 4.3% *\t$132,500.00 plus 5.5% * 8e 8th\tde \u2014from $ 4,000,000 à \u2014to $ 8,000,000\t$129,843.75 plus 2.75% \u2022\t$153,687.50 plus 3.6% *\t$181,687.50 plus 4.25% *\t$242,500.00 plus 5% * Be 9th\tde \u2014from $ 8,000,000 à \u2014 to $10,000,000\t$240,843.76 plus 2.7% *\t$297,687.50 plus 3.55% *\t$351,687.50 plus 4.2% \u2022\t$442,400.00 plus 4.85% * 10e 10th\tde \u2014 from $10,000,000 et au-delà.\u2014 and over\tS294.S43.75 * *\t$:-:«;s.c;s7.5u ' '\t$435,687.50 * *\t$539.400.00 * \u2022 a lo cm %.*Le» *fcgs>TlTT%\\e» «>»s purt'm « I * lo.\u2014 ** \u20ac»f l_l»în |n»r-l-i«>ii «»r pnrt iJu-ri-of. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.2b 3399 4.4 Si des architectes non associés sont charges d'une mission cn collaboration, les honoraires _ sont augmentés de 25%.Cette augmentation s'applique aux ouvrages dont le coût total est inférieur à $5.000,000, et sur la tomme de $5,000,000 lorsque le coût est supérieur à cette somme.4.6 lorsqu'un client retient les services d'un second architecte à titre de conseil en plus de l'architecte retenu pour l'ouvrage, les honoraires de ce dernier n'en sont pas diminués pour autant.5.' insultants 5.1 Sont considérés comme consultants les ingénieurs-conseils dont les services ont été retenus relativement à la construction d'un bâtiment, tels les ingénieurs en structure, en mécanique et en électricité.5.2 Sont également considérés comme consultants tous autres experts-conseils agréés ù la fois par le client et l'architecte et dont les services ont clé retenus relativement à l'ouvrage.5.3 Les honoraires des consultants sont en sus des honoraires prévus pour l'arcliitecte au présent tarif et sont acquittés par le client.C.Mmlifications, restauration et agrandissements 6.1 Pour tous travaux dc modifications ou de restauration, les honoraires de la catégorie applicable sont majorés dc 50%.La même majoration s'applique aux premiers deux mille pieds carrés de superficie de plancher, dans le cas des extensions verticales et des agrandissements latéraux.7.Ilrclierches 7.1 Pour faire les études requises cn fonction de lu préparation complète d'un programme, de la détermination d'une superficie dc terrain en regard d'un programme, de l'établissement de normes ou mitres exigences ou pour toutes autres recherches dans le domaine de l'architecture ou domaines connexes, les honoraires peuvent être calculés sur une liase horaire.8.Groupe domiciliaire 5.1 Pour ses services relativement à des unités d'habitation répétées de la 3e catégorie, l'architecte a droit aux honoraires applicables basés sur le coût dc la première maison complète, et dix pour cent (10%) de ces mêmes honoraires pour chaque unité additionnelle tirée des mêmes plans et devis, dans le même groupe domiciliaire, au même endroit et pour le même client.De plus, I architecte a droit, pour la surveillance des travaux de chaque unité additionnelle, à 50% des honoraires applicables à telle surveillance.8.2 Pour les unités répétées d'habitations poupées de la 2e catégorie, l'architecte a droit »uv honoraires suivants: l Pour cliacune des deuxième et troisième realisations: 50% des honoraires applicables.8.22 Pour chacune des réalisations subséquentes: 40% des honoraires applicables.9.Dirisio*! des honoraires '\u2022' 1 Les honoraires de l'architecte pour tout travail partiel, basés sur le coût total de l'ou-«rage ou sur l'évaluation du coût total de l'ouvrage, sont les suivants: 9.11 Pour les études préliminaires ainsi que les estimés préliminaires: vingt-cinq pour cent i25', t des honoraires applicables.Pour les esquisses seulement: quinze pour cent (15%) ¦es honoraires applicables.Lorsque l'étendue nés services est inférieure A ce que prévoient les dispositions ci-dessus, les honoraires des travaux 8 la journée s'appliquent.4.4 If architects who arc not in partnership are jointly commissioned, the fees sliall he increased by 25%.This applies to work costing under $5.000,000 or to that amount when the cost is higher.4.5 When the client retains a second architect as consultant in addition to the architect commissioned for the project, the lattcr's fees shall not be reduced thereby.5.Consultants 5.1 Consulting engineers \u2014 such as structural, mechanical and electrical engineers\u2014retained in connection with construction of a building are deemed to be consultants.5.2 All other experts accepted by both client and architect and hired for the project are also deemed to lie consultants.5.3 Consultants' fees shall be in addition to those s|»ecified for the architect in this Rate structure and shall he paid by the client.0.Alterations, restoration and extensions 6.1 For all alteration or restoration work, fees in the applicable category shall be increased by 50%.For vertical and lateral extensions, the same increase shall apply to the first two thousand square feet of floor area.7.Research 7.1 Fees may lie calculated on an hourly basis when studies are needed for fully preparing a programme, determining land areas involved in a programme, setting standards and other requirements or undertaking any other research in architecture and associated fields.8.Housing complex 8.1 For services relating to a series of housing units in the 3rd category, the architect sliall be entitled to the applicable fees based on the cost of the first complete house, plus ten per cent 110%) of this amount for each additional unit built from the same plans and specifications, in the same housing complex, at the same location and for the same client.In addition, the architect shall receive 50% of applicable fees for supervising work done on each additional unit.8.2 For series of housing complex units of the 2nd category, the architect shall be entitled to the following fees: 8.21 For each of the second and third units: 50% of applicable fees.8.22 For each subsequent unit: 40% of applicable fees.9.Apportionment of fees 9.1 For any partial work, the architect's fees shall be based on the total cost of the project or an estimate of the total cost, as follows: 9.11 For preliminary studies and estimates: twenty-five per cent (25%) of applicable fees.For sketches only: fifteen per cent (15%) of applicable fees.When the extent of services is less than what is provided for above, per diem fees shall apply. 3400 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n' 25 9.12 Pour les études préliminaires, dessins d'exécution et détails: soixante pour cent (60%) des honoraires applicables.9.13 Pour les études préliminaires, dessins d'exécution, détails et cahier des charges: soixante-dix pour cent (70%) des honoraires applicables.9.14 Pour la surveillance des travaux seulement, lorsque les plans, devis et détails sont fournis par un autre architecte: quarante pour cent (40%) des honoraires applicables.10.Travaux à la journfc 10.1 Lorsque le mode de calcul des honoraires d'après les pourcentages énumérés aux présentes ne s'applique pas et lorsque l'architecte fournit ses services pour des fins telles que mentionnées à l'article 7.1 et telles que consultations, recommandations, enquêtes, inspections ou achats dc matériaux ou d'appareils, rapports, expertises judiciaires, témoignages en cours ou autres services similaires, il a droit à des honoraires proportionnels aux responsabilités encourues et établis comme suit d'après une l>asc minimum per diem.10.2 Les taux per diem pour les patrons et les architectes sur la base d'une journée de six (6) heures et pour les deux premières années de la mise en application du présent tarif, ne peuvent être moindres que: par jour 10.21 Patrons.$140 00 10.22 Assistants seniors.126.00 10.23 Après deux années de mise en application: 10.24 Patrons.150.00 10.25 Assistants seniors.135.00 10.3 Si la journée de travail comprend plus ou moins que six heures, le temps sera rémunéré «\u2022n proportion des taux |)cr diem.10.4 Les taux quotidiens de l'architecte dont les services sont retenus |Kiur fins d'expertise judiciaire sont le double des taux qui précèdent.10.5 Lorsqu'on emploie les taux per dicm |>our les architectes, les dessinateurs et le personnel de secrétariat, les taux suivants sont en vigueur pour les deux premières années de la mise en application du présent tarif: l'heure 10.510 Architectes seniors.$18.50 10.511 Architectes intermédiaires.14.00 10.512 Dessinateurs seniors.14.00 10.513 Dessinateurs intermédiaires.11.00 10.514 Architectes juniors.9.50 10.515 Dessinateurs juniors.7.50 10.516 Personnel de secrétariat.5.50 10.517 Après deux années de mise cn application: 10.518 Architectes seniors.20.00 10.519 Architectes intermédiaires.15.00 10.520 Dessinateurs seniors.15.00 10.521 Dessinateurs intermédiaires.12.00 10.522 Architectes juniors.10.00 10.523 Dessinateurs juniors.8.00 10.524 Personnel de secrétariat____ 6.00 10.6 Est compris le temps employé au bureau île l'architecte, a l'immeuble du client ou ailleurs.Le temps consacré à voyager durant les heures normales de travail doit être facturé en conséquence.Hors les heures normales dc travail, un maximum de trois heures par jour doit être cliargé.9.12 For preliminary studies, working drawing and detail drawings: sixty per cent (Oil' ,f applicable fees.9.13 For preliminary studies, working draw, ings.detail drawings and specifications: seventy per cent (70%) of applicable fees.9.14 For work supTvision only when plans, specifications and detail drawings are provided by another architect: forty per cent 1,40', \u201e[ applicable fees.10.Work by the day 10.1 When the method for calculating fees according to percentages listed in tlii- Kate structure does not apply, and when the architect provides services for purposes such as mentioned under Article 7.1, or such as consultations, recommendations, investigations, inspections or purchases of material or equipment, reparti, judicial inquiries, court testimony or other similar services, he shall be entitled to feci proportional to his responsibilities anil established in accordance with a basic per diem minim uni as follows: 10.2 During the first two years in which this Rote structure is in force, per diem rale- for principals and architects, based on a working day of six (6) hours, shall not he lower than the following.ptr day 10.21 Principals.SI Hi 00 10.22 Senior assistants-.120 00 10.23 The following rates will apply after two years.10.24 Principals.15000 10.25 Senior assistants.135 00 10.3 If the working day is shorter or longer than six hours, time shall he paid in proportion to per dicm rates.10.4 The daily rate for the architect whose services arc secured for judicial inquiries shall he twice the above rates.10.5 During the first two years in which Ihis Rate structure is in force, the following scale shall he paid when per diem rates are used for architects, draftsmen and secretarial personnel.ptr hour 10.510 Senior architects.$18.80 10.511 Intermediate architects .II 0(1 10.512 Senior draftsmen.11 00 10.513 Intermediate draftsmen____ 11.00 10.514 Junior architects.0 50 10.515 Junior draftsmen.7.J9 10.516 Secretarial personnel.5 50 10.517 The following rates will ap- ply after two years.10.518 Senior architects.20 00 10.519 Intermediate architects .15 00 10.520 Senior draftsmen.15 00 10.521 Intermediate draftsmen____ 12 00 10.522 Junior architects.10 00 10.523 Junior draftsmen.8.00 10.524 Secretarial personnel.\"00 10.6 Time spent in the architect's oilier, the client's premises or elsewhere sliall be counted.Time spent travelling during regular working hours shall be billed accordingly; outside regular working hours, a maximum of three hours a day shall be charged. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 .3401 10.7 De plus, l'architecte doit être remboursé de toutes dépenses raisonnables encourues au cours de ses services.10.8 Tout autre service rendu par le personnel non compris dans la liste ci-dessus est rémunéré suivant le coût réel des salaires bruts augmenté de cent cinquante pour cent (150%).11.Évaluation de propriétés 11.1 Pour la préparation d'une évaluation ¦l'immeuble nécessistant des relevés et des estimés détaillés, les honoraires sont 40% des honoraires indiqués dans chaque catégorie de l'article 4.3, basés sur la valeur courante dc remplacement île l'immeuble, plus des honoraires basés sur les taux des travaux à la journée pour le temps consacré devant les tribunaux ou autres corps publics pour rendre témoignage sur cette évaluation.12.Relevé de bâtiments et toisé de travaux 12.1 Les honoraires pour travaux à la journée s'appliquent à la préparation de relevés des bâtiments existants.12.2 Pour le toisé des travaux faits ou à faire, les honoraires pour les travaux à la journée s'appliquent, mais le minimum des honoraires doit être île deux pour cent (2%) dc la valeur courante de remplacement de la propriété.13; Travaux non exécutés 13.1 Kn plus des honoraires basés sur le coût total des travaux exécutés, l'architecte a droit aux honoraires pour ses services sur tous les Ira vaux projetés d'après les instructions du ¦ lient, mais non exécutés par la suite.i I.Services supplémentaires 11.1 Toutes modifications importantes apportées au cours de la préparation des plans ou de l'exécution du projet, par suite de changement de terrain ou de programme, donnent lieu à des honoraires supplémentaires. défaut d'une en-lente préalable entre le client et l'architecte, le tarif des travaux à la journée s'applique pour ces services supplémentaires.14.2 Si le client, après avoir approuvé un plan précis, demande des modifications cul rainant, les services ou frais supplémentaires relatifs aux changements ou additions aux plans d'exécution ¦ m aux devis descriptifs ou autrement, ou si l'architecte est appelé i\\ rendre des services supplémentaires ou à encourir des frais en raison de délais occasionnés par le client ou un entrepreneur, ou cn raison de la faute, de l'insolvabilité, ou du décès de l'un ou l'autre de ces intéressés, ou par suite de cas de force majeure, l'architecte doit être équitablement rémunéré pour ces services et frais supplémentaires.14.3 Pour mettre les dessins à jour, consigner tous les changements dc la construction dus ù des revisions des dessins originaux et préparer des dessins reflétant ces changements, l'architecte doit recevoir pour ce service supplémentaire nue rémunération basée sur les taux des travaux à la journée.15.Contrats distincts avec sous-traitants et contrats au prix coûtant, plus un pourcentage 15.1 Lorsque les travaux sont exlcutés en vertu de contrats distincts avec les sous-traitants, sauf lorsqu'il s'agit de mécanique et d'électricité, ou lorsque les travaux doivent être exécutes en vertu d'un contrat au prix coûtant avec pour- 10.7 Furthermore, the architect must be reimbursed for all reasonable expenses incurred wliile dispensing his services.10.8 Any other service provided by personnel not included in the above list shall be paid on the basis of the actual cost of gross salaries increased by one hundred and fifty per cent (150%).11.Property assessments 11.1 For preparing property assessments requiring detailed surveys and estimates, fees shall be 40% of those indicated in each category under Article 4.3, based on the current replacement value of the property, plus fees based on the daily work rates for time spent before the courts or other public bodies to certify such assessments.12.Building and quantity surreys 12.1 Fees for work done by the day shall apply to the preparation of surveys for existing buildings.12.2 For evaluating work done or to be done, fees for work by the day shall apply, but minimum fees shall be two per cent (2%) of the current replacement value of the property.13.Work not carried out 13.1 In addition to fees based on the total cost of the work carried out.the architect shall l>e cut itled to receive payment for all work stipulated in the client's instruction but not subsequently carried out.14.Additional services 14.1 All major modifications resulting from a change of site or programme and made while plans are being prepared or a project is being carried out shall entail additional fees.In the absence of previous agreement between client and architect, rates for work by the day shall apply to these additional services.14.2 If.after having approved a specific plan, the client asks for modifications leading to additional services or exjienses resulting from changes in working drawings, specifications or anything else, or if the architect is called upon to render additional services or incur expenses because of delays caused by the client or a contractor, or as a result of default, insolvency or death of one or other of the two interested parties, or attributable to an act of God, the architect shall receive fair payment for such services and additional expenses.14.3 For additional services required to bring drawings up to date record all construction changes resulting from revisions to original drawings and prepare new plans incorporating such changes, the architect shall lie paid on the basis of rates for work done by the day.15.Separate contracts with subcontractors and cost-plus contracts 15.1 When a project is carried out under separate contracts with .subcontractors, the architect's fees sliall l>c increased by twenty per cent (20%), except when mechanical and electrical work is involved, or when the contract calls for the project 3402 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n' 25 centagc ou honoraires fixes en sus, les honoraires de l'architecte doivent être augmentés de vingt pour cent (20%).16.Déboursés 16.1 Les honoraires prévus à la présente cédulc s'appliquent aux travaux exécutés dans un rayon de cinquante milles du lieu où est situé le bureau de l'architecte.Lorsque le site des travaux est au-delà de cette limite et entraîne pour l'architecte des dépenses additionnelles de temps et d'argent en voyages, appels téléphoniques ou télégrammes, le client doit lui rembourser ces dépenses additionnelles.16.2 Lorsque l'architecte voyage à la demande du client, ce dernier doit lui rembourser toutes ses dépenses.16.3 Lorsqu'au bénéfice du client, l'architecte fait des déboursés pour expertise, demande et obtention dc permis des autorités publiques, copies additionnelles de dessins ou documents (au-delà de dix copies) et tous autres déboursés spéciaux, y inclus les négatifs des dessins d'exécution exigés par le client, ce dernier doit lui en reml)ourser le coût, plus 10% dc frais d'administration.17.Abandon ou suspension îles trataux 17.1 Si l'ouvrage entrepris pir l'architecte est abandonné ou différé en tout ou cn partie par le client, l'architecte a alors droit à la partie applicable des honoraires calculés d'après l'évaluation du COÛt total de l'ouvrage projeté.18.Renseignements que doit fournir le client 18.1 I* client doit fournir à l'architecte un relevé complet du terrain, comprenant tous les renseignements et les services d'arpenteur requis pour l'implantation des constructions et donnant tous les niveaux et lignes de rues, les pavages, les propriétés adjacentes et les constructions sur le lot; il doit également fournira l'urcliitectc des renseignements complets quant aux droits, obligations, servit tides, bornes et contours du site dc la construction et quant aux égouLs, à l'aqueduc, au gaz, à l'électricité ou aux services similaires (ou rembourser l'architecte des frais qu'il aura encourus à cette fin).Le client doit payer les forages ou sondages, les essais chimiques, mécaniques ou autres et les inspections.I/c client doit aussi payer toute annonce se rapportant à l'obtention des soumissions, les |>ermis.les licences, etc.et les services juridiques nécessaires.19.Paiement des honoraires 19.1 Les honoraires sont, exigibles et payables au fur et à mesure dc l'exécution des services de l'architecte dans la proportion indiquée à l'article 9, « Division des honoraires » et dans les autres cas lorsque les services sont rendus.19.2 Ix\\s honoraires pour la surveillance des travaux dc construction sont dus et payables mensuellement cn proportion des travaux exécutés.Aucune retenue ne doit être faite sur le versement dc tels honoraires, même si les paiements à l'entrepreneur y sont sujets.19.3 Dans le cas des travaux complexes ou île longue durée, des paiements ù compte des honoraires de l'arcliitecte peuvent, dans les limites correspondant à la division énoncée à l'article 9 mentionné ci-dessus, être effectués au cours dc la préparation des études préliminaires ou dessins d'exécution ou des devis, sur une hase mensuelle ou autre selon ce qui aura été convenu entre l'architecte et le client.to be completed at cost with a percentage or art fee added.10.Expenses 16.1 Fees listed in the present Rate structure shall apply to projects within a radius of fifty miles from the architect's oflice.When the construction site is beyond this limit and compl-the architect to spend more time and money for Ira v.el, telephone calls or telegrams, the client -hall reimburse him for such additional expenses, 16.2 When the architect travels at the cli( nt'a request, the latter shall pay all expenses.16.3 When, on behalf of his client, the architect incurs expenses for expert opinions, permits from public authorities, additional copies of drawings or documents (over ten copies) ami all other extras, including negatives of working drawings requested by the client, the latter shall repay the cost, plus 10% for administration charges.17.Cancellation or suspension of projects 17.1 If a project undertaken by the architect is cancelled or deferred by the client, in whole or in part, tbcarchitectshnll be entitled to the applicable part of fees based on estimated total cost of the project.18.Information irhich the client must provide 18.1 The client must provide the architect with complete data for the site, including all surveying information and details required for siting buildings: elevations and street lines, pavements, adjacent properties and construction- on the site; he must also give the architect full information on rights, obligations, servitudes, boundaries and contours related to the construction site, and on sewer, water, gas, electricity or similar services (or reimburse the architect for cxpen-c-incurred for that purpose).The client shall pay for 1 wrings or soundings, chemical, mechanical or oUicr tests and inspections.The client shall BUO pay for any advertisement concerning tender calls, permits, licences, etc., and necessary leual services.19.Payment of fees 19.1 Fees shall be due and payable as services are performed by the architect in the proportion indicated under Article 9, \"Apportionment of fees\", and, in other cases, when services have been rendered.19.2 Fees for supervising construction worl shall be due and payable monthly in proportion to the work done and, unlike payments to the contractor, they shall not be subject to with holding.19.3 For complex or long-lasting projects, the architect may receive partial fee payments, within limits corresponding to the apportionment given under Article 9, during the preparation of preliminary studies, working drawings or specilica tions, on a monthly or other basis according to whatever agreement may have been reached between the architect and his client. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3403 20.Version officielle 30.1 La version française de la présente cédule constitue le tarif officiel des honoraires se rappor-taut aux services professionnels des membres de l'Association des architectes de la province de Québec.CÉDULE B Honoraires auxquels les membres de la Corporation des Ingénieurs du Québec ont droit pour leurs services.Dispositions interprétatives 2° Les expressions ci-après ont, dans le présent document, le sens suivant: n) « Corporation » signifie la « Corporation des Ingénieurs du Québec » ; li) < ingénieur» signifie un membre de la Corporation ou le détenteur d'un permis temporaire émis par elle; r) « tarif » signifie le « Tarif des honoraires de l'ingénieur».3° Le présent tarif détermine la rémunération minimale que l'ingénieur dans la pratique du génie-conseil doit recevoir pour services pro-fessionnels rendus en l'absence d'une convention stipulant une rémunération plus élevée.Première partie Services d'ingénieur 4° Les services de génie offerts par les ingénieurs-conseils couvrent presque tous les aspects de notre économie industrielle.Dans le but de déterminer une base de rémunération appropriée, on peut classifier les services rendus par l'ingénieur en six divisions générales, comme suit: 1.Services consultatifs 2.Études préparatoires .'1.Plans et devis préliminaires 1.Plans et devis définitifs â.Services durant la construction ti.Services spéciaux relatifs au projet Ces divisions sont décrites aux paragraphes suivants: Division 1 Services consultatifs 5° Ces services peuvent comprendre des consultations, conseils, expertises, estimations, évaluations, études des structures de taux et tarifs, inspections, essais ou autres services concernant la compilation, l'analyse, l'évaluation et l'interprétation de données et d'informations permettant d'aboutir à des conclusions et des recommandations spécialisées.Division 2 Études préparatoires 6° Ce sont des services destinés à établir les bases de la préparation des plans et devis pour 'les projets d'un caractère particulier.Ils peuvent comprendre des recherches, explorations, relevés, éludes du sol, analyse des conditions ou de plusieurs solutions possibles, y compris les études économiques, les coûts d'exploitation ou autres sujets de même nature, le tout devant servir de base à des conclusions ou des recommandations relatives à la mise en marche d'un projet spécifique.Ces services comprennent aussi les levés et recherches pour modifications et additions aux ouvrages existants.20.Officiai version 20.1 The French version of this Rate structure shall be considered as the official tariff of fees for professional services rendered by members of the Province of Québec Association of Architects.RATE STRUCTURE B Fees to which members of the Corporation of Engineers of Québec are entitled for thei r services.Interpretation 2.In this document the following expressions have the following meanings: (a) \"Corporation\" means the \"Corporation of Engineers of Québec\"; (6) \"Engineer\" means a member of the Corporation or the holder of a temporary licence issued by the Corporation; (c) \"Tariff\" means the \"Engineer's Tariff of Fees\".3.The tariff determines the minimum remuneration which the engineer in consulting practice must receive for professional services rendered, in the absence of an agreement stipulating a higher remuneration.Part One Engineering Services 4.The engineering services offered by Consulting Engineers cover almost every aspect of our industrial economy.For the purpose of determining an appropriate fee basis, the Engineer's services may be divided into the following six broad divisions: 1.Advisory Services 2.Preparatory Studies 3.Preliminary Plans and Specifications 4.Final Plans and Specifications 5.Services During Construction 6.Special Services Relative to the Project These divisions are described in the following paragraphs.Division 1 Advisory Services 5.These services may consist of: consultation, advice, expert testimony, appraisals, valuations, rate structure and tariff studies, inspection, testing or other services concerning the collection, analysis, evaluation and interpretation of data and information leading to specialized conclusions and recommendations.Division 2 Preparatory Studies 6.These are services to establish the basis for the preparation of plans and specifications for projects having peculiar characteristics.They may consist of investigations, exploration, surveys, soil investigation, analysis of conditions or of several alternative plans, including economic studies, operating costs and similar matters, as a basis for conclusions and recommendations on the undertaking of a specific project.They also include surveys and investigations for alterations and additions to existing works. 3404 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1908, 100' année, n\" 25 Division 3 Plans et devis préliminaires 7° Ces services comprennent la préparution et la présentation par l'ingénieur de documents techniques tels que croquis, plans préliminaires, devis sommaires, estimation préliminuire du coiït «les travaux et/ou un rapport jxnir indiquer clairement sa conception «le la solution technique proposée, pour approbation et acceptation par le client.Ils comprennent aussi en génie routier, les levés et les tracés nécessaires à la préparation «les plans préliminaires.8° La préparation de ces documents préliminaires |>eut être fondée sur des informations fournies directement pir le client, ou sur les résultats «l'études pré'paratoires approuvées j>ar le client, lorsque s'appliipie la Division 2 (Etudes préparatoircs-O0), Ce travail ne comprend pas l'étude comparative détaillée de méthodes, matériaux ou systèmes, laquelle doit ètre effectuée dans le cadre des éludes préparatoires avec l'approbation du client.Division 4 Plans et devis dêfin il if g 9° Ces services viennent après que l'on a établi, en vertu des divisions précédentes, les bases dc la solution technique définitive et que le client les a reçues et formellement approuvées.Ces services comprennent ce qui suit: a) Préparation «les dessins propres aux besoins de la construction.b) Préparation des devis complets et «les documents «le soumission.c) Rcvision(s), s'il y a lieu, de l'estimation préliminaire.d) Analyse «les soumissions cl recommandations appropriées «punit à leur acceptation ou leur rejet.e) les borderaux de quantité avec prix unitaires estimatifs pour les travaux qu'il est d'usage «l'accorder à prix unitaire.f) Dans les ouvrages de ponts et chaussées, les relevés et les tract's nécessaires à la préparation des plans définitifs.Division 5 Services durant la construction 5A.Services rendus au bureau: 10° Ceci comprend les services rendus au bureau durant la construction, tels «pic décrits ci-après: a) Conseils au client sur les problèmes techniques qui peuvent survenir au cours de la construction et nécessitent considération, mais aucune visite au chantier.b) Vérification des dessins d'atelier et des dessins des fabricants afin de s'assurer qu'ils sont généralement conformes aux plans et devis émis par l'ingénieur.c) Correspondance relative aux travaux dc construction.d) Approbation de substituts dans les méthodes et les matériaux après entente avec le client.SB.Services rendus au chantier (sans rêdidenl): 11° Ceci comprend les services rendus au chantier durant la construction, tels que décrits ci-après: Division 3 Preliminary Plans and Specifications 7.These services include the preparation and the submission by the Engineer of such technical documents as sketches, preliminary plans, specification notes, preliminary estimate of the cost of the works and or report to clearly indicate Ids concept of the design, for approval and acceptance by the Client.In highway engineering, they also include surveys and layouts required for the preparation of the preliminary plan-.8.The préparation of these preUminary documents may be based on information supplied directly by the Client or.when Division 2 applies (Preparatory Studies-Oi.on the results of Preparatory Studies approved by the Client.It doci not include detailed studies of alternate methods, materials or systems, which are to lie carried out under the Preparatory Studies with the Client's approval.Division 4 Final Plans and Spécifications 9.These services follow after the basis for final design has been established under the foregoing, ami has been submitted t and formally accepted liy the Client.They shall include the following: (a) Preparation of drawings suitable for eon-struetion purposes, (l>) Preparation of complete specifications and tender documenta.(«\u2022) lté vision (s), as may Ik- necessary, of the preliminary estimate.Analysis of tenders and recommendations for acceptance or rejection as «leemeil advisable.(as être inférieurs à: Jour 1.Patrons.$140.00 2.Chefs de services et ingénieurs en ebef.126.00 S'il y a convention, le rétle de chacun y sera défini.Apre- deux ans de mise cn application: 1.rations.150.00 2.( hefs dc services et ingénieurs en chef.135.00 2la Aux lins du calcul de In rémunération par la méthode Per Diem, six heures constituent une journée de travail: si le travail occupe plus ou nioin- de six heures dans une même journée, le temps consacré au travail doit être compté proportionnellement au taux quotidien.22* Lorsque la méthode Per Diem est employée pour d'autres classes d'ingénieurs, ainsi (pie pour le personnel auxiliaire, les taux pour le» deux premières années de la mise cn application de la présente cédulc sont: Ingénieurs Heure 3.Ingénieurs seniors.S 18.50 4.Ingénieurs intermédiaires.14.00 5.Ingénieurs juniors.0.50 Personnel auxiliaire 1.Techniciens et dessinateurs seniors.$ 11.00 Techniciens et dessinateurs intermédiaires.9.50 t Techniciens et dessinateurs juniors.7.50 4.Kmployés de bureau préposés à la préparation de rapports et autres documents se rapportant directement au projet.5.50 Après deux années de mise en application: Ingénieurs 3.Ingénieurs seniors.$ 20.00 4- Ingénieurs intermédiaires.15.00 5.Ingénieurs juniors.10.00 Personnel auxiliaire 1 -Techniciens et dessinateurs seniors.$ 12.00 2.Techniciens et dessinateurs intermé- diaires.10 00 3.l'echuicicns et dessinateurs juniors.8.00 1 Kmployés de bureau préposés ù la préparation de rapports et autres documents se rapportant directement au projet.6.00 18.The methods of computation and the application of the foregoing schedules to the various engineering services are explained in the following.Schedule A; Per Diem Basis 19.The Per Diem basis is applicable to all engineering services but is recommended for such services as consultations, advisory services, reports, establishing data and requirements for design, research, investigations, inspection of material or equipment, court cases and similar services.20.In the first two years during which the present Hate structure shall apply, the Per Diem rates for principals, executive and chief engineers shall be not less than: Dag 1.Principals .$140.00 2.Executive and Chief Engineers.126.00 If an Agreement is drawn, the duties of the above Engineers shall Ite defined therein.After those two years: 1.Principals.150.00 2.Executive and Chief Engineers.135.00 21.For the purpose of calculating the remuneration on the Per Diem basis, six hours shall lie taken as a working day; if more or less than six hours in any one day is occupied by the work, the time sliall he charged in proportion to the daily rate.22.When Per Diem rates are used for other classes of Engineers and for Staff Assistants, the charges in the first two years during which the present Rate structure shall apply shall be as follows: Engineers Hour 3.Senior Engineers.S 18.50 4.Intermediate Engineers.14.00 5.Junior Engineers.9 50 Staff Assistants 1.Senior Technicians and Draftsmen.$ 11.00 2.Intermediate Tecluiicinnsand Drafts- men.9.59 3.Junior Technicians and Draftsmen.7.59 4.Clerical Staff on reports or other documents directly applicable to the work.5.50 After those two years: Engineers 3.Senior Engineers.$20.00 4.Intermediate Engineers.15.00 5.Junior Engineers.10.00 Staff Assistants 1.Senior Technicians and Draftsmen.$ 12.00 2.Intermediate Technicians and Draftsmen.10.00 3.Junior Technicians and Draftsmen.8.00 4.Clerical Staff on reports or other documents directly applicable to the work.600 3408 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, »° 25 23° Tout le temps consacré au travail, que ce soit au bureau de l'ingénieur, aux bureaux du client, ou ailleurs, doit être débité.Le temps requis |wur tout voyage durant les heures normales de travail doit être compté.Le temps consacré aux déplacements durant les heures non ouvrables sera débité au compté du client jusqu'à Concurrence de trois (3) heures pur jour.24° Tout le temps, à la demidieure près, que l'ingénieur et son personnel consacrent au projet doit être dûment enregistré chaque jour.25° Les ingénieurs et le personnel auxiliaire peuvent être classifies dans les group-s indiqués ci-dessus en déterminant pour chacun des membres du personnel son « tau horaire », tel que défini dans la « Méthode du salaire .à l'article 31.puis en y ajoutant 150',' pair obtenir son taux horaire brut: chacun des membres du personnel est alors classifié dans le groupe le plus rapproché dc son taux horaire brut.20° De plus, l'ingénieur doit être remboursé (le toutes les dépenses légitimes encourues dans l'accomplissement de ses services, y compris les « dep-nses définies décrites à la clause 03.27° Lorsque le client désire insp-cter ou vérifier les registres de temps et les déboursés de l'ingénieur, afin de contrôler le bien-fondé des montants qui lui sont facturés, l'ingénieur doit permettre cette inspection ou «rite vérification à un moment convenant aux deux parties et accorder toute l'aide nécessaire p>ur en faciliter l'exécution.Mode de rémunération II; méthode du salaire.28° I,c mode de rémunération basé sur le salaire s'applique à tous les services d'ingénieur, mais on le recommande surtout dans les cas où il n'est pas possible d'établir avec précision l'étendue du travail au moment où le client le confie à l'ingénieur, ou lorsque le coût des services de génie requis n'a pas un rappirt normal avec le coût des travaux.Tableaux de» taux 29° L'ingénieur doit être rémunéré sur la base suivante: Sur le 1er $10.000 de « coût des salaires \u2022 ou partie d'icelui-Coût des salaires + 150%; Sur le 2e 810.000 de « coût des saloin-s » ou partie d'icelui \u2014 Coût des salaires -f 140%; Sur le 3e 810.000 de * coût des salaires > ou partie d'icelui \u2014 Coût îles salaires + 130%; Sur le 4c 810,000 de « coût des salaires » ou partie d'icelui \u2014 Coût des salaires + 120%; Sur le 5e 810,000 de « coût des salaires » ou partie d'icelui \u2014 Coût des salaires + 110%; Sur tous les montants de « coût des salaires » au delà de 850,000\u2014Coût des salaires + 100%.30° Le « coût des salaires > est la somme totale «le la « rémunération » payée aux ingénieurs, techniciens, dessinateurs et autres employés assignés au travail technique, ainsi qu'au personnel dc bureau préposé à la préparation dc rapports, devis et autres documents se rapportant directement au projet exclusion faite des services exécutifs et administratifs.81* La « rémunération» est définie comme le produit «lu nombre d'heures consacrées au projet, y compris le temps supplémentaire et celui consacré aux voyages, tel que défini dans la clause 23, par le « taux horaire > établi pour chaque 23.All time expended on the work whether in the Engineer's office, at the Client's premi-.-, or elsewhere, sliall be included.If travelling lime is required during normal working hours, the lime so used is properly chargeable.If such travelling is done outside of normal working hours, the time is chargeable up to a maximum of 3 hours per day.24.The actual time, to the nearest half hour, spent on the project by the Engineer and his staff must be properly recorded daily.25.Engineers and Staff Assistants may he classified into the above groups by determining for each staff member involved his \"Hourly Kate\", as defined in the Salary basis (311, plus 150% to arrive at his gross hourly rate, each being thereupon assigned to the group closest to his gross hourly rate.26.In addition, the Engineer shall be reimbursed for the actual cost of all disbursement! made by him for expenses properly incurred in the performance of his services, including those specific items defined in clause 63.27.Should the Client desire at any time to inspect or audit the Consulting Engineer's time and out-of-pocket expense records in order to substantiate the time and expenses claimed for the Project, the Engineer will allow such inspection or uudit at a mutually agreeable time.The Engineer shall render all assistance required to facilitate such inspection or audit.Schedule B; Salary Basis 28.The Salary Basis is applicable to all engineering services, but is recommended particularly where it is not pissible to state accurately the scope of work at the time the Engineer is retained for the project or when the cost of engineering services required docs not bear the usual relationship to the cost of the works.Table of Rales 29.The Engineer is to be remunerated on the following basis: On the 1st $10,000 of \"Salary cost\" or on any portion thereof \u2014 Salary Cost 4- 150%; On the 2n«l $10,000 of \"Salary cost\" or on any portion thereof \u2014 Salary Cost 4- 140%; On the 3rd $10,000 of \"Salary cost\" or on apportion thereof \u2014 Salary Cost + 130%; On the 4th $10,000 of \"Salary cost\" or on apportion thereof \u2014 Salary Cost + 120%; On the 5th $10,000 of \"Salary cost\" or on any portion thereof\u2014Salary Cost 4- 110%; On all amounts of \"Salary cost\" over $50,000 \u2014 Salary Cost + 100%.30.The \"Salary Cost\" consists of the total sum of the \"Remuneration\" paid to engineers, technicians, draftsmen, employees engaged in technical work, and clerical staff working 00 reports, specifications and other documents directly applicable to the project, as distinguished from general, executive and administrative services.31.The \"Remuneration\" is defined as the product of the number of hours expended on the project including overtime and travelling time, as defined in clause 23, by the \"Hourly Bate' established for each individual.The \"Hourly QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968.Vol.100, No.25 3409 iiuli\\ itlu.Le « taux horaire » est établi en divisant pur 1.800 heures, le salaire annuel brut, y compris toutes les allocations régulières payées à l'employé, mais à l'exclusion des bénéfices marginaux.Ce nombre d'heures tient compte des vacances et des fêtes légales.:SJ Le nombre d'heures, à la demi-heure près, consacrées par l'ingénieur et son personnel à chaque projet doit être dûment enregistré chaque jour, et le client ne sera facturé que le temps réel consacré à son projet.33 Le temps des patrons, chefs dc services et ingénicurs-cn-chcf cn autant qu'ils rendent des services techniques et consultatifs s'appliquant ipéciSquement au projet, est rémunéré selon la méthode Per Diem.l)c plus, l'ingénieur doit être remboursé de toutes les dépenses légitimes encourues dans l'accomplissement de ses services, y compris les « dépenses définies \u2022 décrites ù la clause 03.31 Les dépenses que doit assumer l'ingénieur comprennent notamment: les bénéfices marginaux, i.e., assurances-groupe vie, accidents et maladie, caisses dc retraite, salaire payé au CM de maladie; les salaires et dépenses dc voyage concernant l'administration; le loyer des bureaux; l'éclairage; le service téléphonique et la téléphoniste requise; les taxes d'eau et d'affaires; les assurances responsabilité feu et vol; les frais dc dépréciation; les fournitures de bureau; les frais bancaires: la réparation et l'entretien de l'équipement dc bureau; les frais dc comptabilité et de classement des documents; les frais normaux de comptabilité et dc conseils juridiques; les manuels internes dc nonnes dc conception et d'exécution des plans; messagers; cotisations à de- associations d'ingénieurs et abonnements à des publications techniques; bibliothèque et bibliothécaire; résumés de publications techniques; publicité; espace raisonnable de bureau pour le représentant du client; et autres frais semblables.3r)° Lorsque, dans un cas donné, la méthode du salaire est employée pour calculer les honoraires |)our une partie des services, il faut tenir compte dans la détermination du taux applicable de ladite méthode, des montants gagnés, par ordre chronologique, selon la méthode Per Diem cl ou la méthode dc pourcentage.36\" Lorsque le client désire inspecter ou vérifier les registres dc temps, de salaires et des déboursés de l'ingénieur afin dc contrôler le bien-fondé des montants qui lui sont facturés, l'ingénieur doit permettre cette inspection ou cette vérification à un montant convenant aux deux parties et accorder toute l'aide nécessaire pour en faciliter l'exécution.Mode de rémunération C; méthode de pourcentage 37\" Cette méthode s'applique aux services d'ingénieurs énumérés dans les divisions 3, 4, BA, 5B, 5C, pour les projets de type conventionnel.L'utilisation dc cette méthode implique qm; des études préparatoires destinées à définir clairement la portée et l'étendue du projet ont été complétées et que ces études démontrent le caractère conventionnel du projet.C'implexiti du travail 381 L'ingénieur est appelé à fournir ses services professionnels à l'égard de nombreux types de travaux requis par l'industrie, le commerce et les autorités gouvernementales.Il est évident Rate\" is established by dividing by 1,800 hours the gross annual salary including any regular allowances paid to the employee but exclusive of all fringe benefits.This number of hours includes an allowance for vacation and legal holidays.32.The actual hours, to the nearest half hour, spent by the Engineer and his staff on each individual project must be properly recorded daily, and the client will be charged only for the actual time spent on his project.33.Principals, Executive and Chief Engineers to the extent that they perform technical and advisory services applicable to the particular project sliall be paid according to the Per Diem schedule.In addition, the Consultant sliall be reimbursed for the actual cost of all disbursements made by him for expenses properly incurred in the performance of his services as outlined in clause 63.34.The cost items to be borne by the Engineer include such costs as: salary fringe benefits, i.e., group life, accident and health insurance, pension fund, sickness pay; salaries and travelling related to administration; office rent; light; telephone service and operator; business and water taxes; liability fire and theft insurance; depreciation charges; office supplies; bank charges; office equipment repairs and maintenance; liookkceping ami filing costs; normal legal and auditing charges; office design standard manuals and drawings; messengers; subscriptions to engineers' associations and trade magazines; library and librarian; technical abstracts; publicity; reasonable office space for the client's nominee; and other similar costs.35.When the Salary Basis is used to compute the fees for part of the services in any given case, the amount of fees earned under the Per Diem basis and/or the Percentage Basis shall be taken into account, in their chronological order, in determining the applicable rate under the Salary Basis.36.Should the client desire at any time to inspect or audit the Consulting Engineer's time, salary and out-of-pocket expense records in order to substantiate the time and expenses claimed for the Project, the Engineer will allow such inspection or audit at a mutually agreeable time.The Engineer shul I render all assistance required to facilitate such inspection or audit.Schedule C; Percentage Basis 37.This method is applicable for engineering services, as listed in Divisions 3, 4, 5A, 5B, 5C, for projects of conventional design.This implies that preparatory studies have been completed to clearly define the scope and extent of the project and that such studies point to a conventional design for the project.Complexity of Work 38.The Engineer is expected to render his professional services for many different types of works required by industry, commerce and public works authorities.It is recognized that 3410 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, h\" 25 que les problèmes dc conception et de construction inhérents n la réalisation d'un projet complexe imposent A l'ingénieur une responsabilité et our les bâtiments: 45\" Les honoraires pour services rendus relativement aux fondations et ù la charpente d'un haliment se calculent en appliquant au coût desdits travaux le taux approprié dc la catégorie \"laiis laquelle se situent les travaux suivant la présente classification.(8) Highways, eontrollcd-access expressways in rural surroundings, including interchanges and other related works; highway lighting; (9) Landing fields, small airports with minimum facilities; (10) Playgrounds, landscaping, grading and paving.43.Category II: (1) Bridges ami viaducts whose non-repetitive elements, curvature, skew and inclination arc imixirtant factors; tunnels; (2) Flood control works and pumping stations; (3) Large interceptor and relief sewers; (4) Locks, canals, wharves and simple harbour works; (5) Streets, sidewalks, controllcd-access expressways in urban surroundings, including interchanges and other related works; 1,0) Large airports with extensive facilities; (7) Food processing plants anil breweries; (8) Simple textile mills; (9) Mines, ore processing plants and foundries; (10) Electrical substations, power lines and distribution systems, excluding arctic and muskeg installations; (11) Diesel-electric generators un«lcr 1,000 Kw.capacity; (12) Railways including tunnels and normal facilities; (13) Industrial assembly plants; (14) Silos and grain elevators.44.Category III: (1) High dams of arched or hollow-gravity typ- with special control features, also earth or rock fill dams over 200 ft.high, (2) Complex harbour works including freight handling facilities.(3) Very complex engineering works.(4) Water purification plants.(5) Primary and secondary sewage treatment ami disposal plants; (6) Treatment and disposal of industrial wastes.(7) Hydro and thermal power plants; (8) lia- turbine plants and diesel generators over 1,000 Kw.capacity; (9) Material handling and conveying systems; (10) Pulp, paper and I ma id mills; (11) Power line carrier, VHF and HF systems, for relaying and communication; (12) Micro-wave communication, television and radio broadcasting.Foundations and Structures for Buildings 45.The fees for services regarding the foundations and structure of a building shall be computed by applying the proper category rate, such category being selected in accordance with this classification, to the cost of the said works, 3412 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1908, 100' année, n\" 25 46° Catégorie I: 1) Entrepôts et vastes constructions à haies multiples, écoles primaires sans gymnase ni auditorium.2) Manèges militaires, hangars et garages publics à toits plats.3) Ateliers mécaniques, fabriques p>ur industrie et autres bâtiments industriels d'une construction à baie type.47° Catégorie II: 1) Arenas, auditoriums, hôpitaux, sanatoriums, cliniques et lal>oratoires dc recherches.2) Écoles avec gymnase et/ou auditorium, centres récréatifs, bibliothèques et théâtres; 3) Grands édifices à bureaux, hôtels et maisons d'appartements; 4) Magasins de détail, centres commerciaux ou d'exposition.5) Bâtiments de la caté-gorie I, nécessitant rétablissement sur pieux ou d'autres méthodes spéciales de traitement des fondations.48° Catégorie III: 1) Bâtiments de caractère monumental, églises, musées.2) Bâtiments industriels de construction complexe dans lesquels la forme du bâtiment est déterminée par la machinerie.Installations électrique cl mécaniques pour 1rs bâtiments: 49e Les honoraires pour services rendus relativement aux installations électriques et mécaniques d'un bâtiment se calculent en appliquant au coût dcsdils travaux le taux approprié de la catégorie dans laquelle se situent les travaux suivant la présente classification.50° Lorsque des parties des travaux se situent dans des catégories différentes, les horaires s'établissent au moindre des deux montants calculés comme suit: a) En appliquant le taux approprié de chaque catégorie concernée à la partie correspondante du coût des travaux et en faisant la somme de ces résultats.i) En appliqua i.t au coût total desdits travaux le taux approprié de la plus élevée des catégories cn question.51° Catégorie I: Xon existante 52° Catégorie II: Plomberie et chauffage conventionnels.Distribution électrique pour éclairage et force motrice conventionnels.Ventilation par évacuation avec conduits simples.l>our les bâtiments suivants: Entrcp'its.manèges militaires, hangars, garages publics, fabriques pour industrie légère.53° Catégorie III: Plomberie, chauffage à l'eau chaude, à la valeur ou ù l'électricité, distribution électrique pour éclairage et force motrice, climatisation sans conduits de distribution.pour les bâtiments suivants: Grandes maisons d'appartements et hôtels de plus de cinq étages.Écoles primaires.Auditoriums, centres récréatifs, arenas.Édifices pour bureaux ou pour fins d'exposition.Magasins dc détail et centres commerciaux.Laboratoires.Hôpitaux, cliniques, sanatoriums, écoles polyvalentes ou secondaires, universités et les bâtiments industriels de caractère simple 46.Category I: (1) Warehouses and large open structures of multiple bays and elementary schools without gymnasiums or auditoriums; (2) Armouries, hangars and public garages with flat roofs; (3) Machine shops, light manufacturing plants and other industrial buildings of a typical bay-construction.47.Category II : (1) Arenas.auditoriums, hospitals,sanatoriums, clinics and research laboratories; (2) Schools with gymnasiums and or audita-riuins, recreational buildings, libraries and theatres; (3) Large oflice buildings, hotels und apirt-incuts; (4) Retail stores, shopping display centres: (5) Buildings in Category I.requiring piling or other sp-cial treatment of the foundations.48.Category III: (1) Monumental buildings, churches and museums; (2) Industrial buildings of complex construction, where the form of the building is determined by equipment.Mechanical and Electrical Systems for Building): 49.The fees for services regarding the mechanical and electrical systems for a building shall lie computed by applying the proper category rate, such category living selected in accordance with this classification, to the cost of the said works.50.Whenever portions of the works fall into different categories the fees shall be the les-er of the amounts obtained as follows: (a) By applying the applicable category rate to each corresponding portion of the cost of the works and totalling these results.(6) By applying the highest of the applicable category rates to the aggregute cost of the works.51.Category I: N'on-existent 52.Category II: Conventional plumbing and heating.Conventional lighting and jwwer distribution.Exhaust ventilation with simple ductwork.for the following buildings: Warehouses, armouries, hangars, public garages, light manufacturing plants.53.Category III: Plumbing, hot water or steam heating, electrical heating, lighting and power distribution, air conditioning without ductwork.for the following buildings: Large Apartments and Hotels over 5 stories ID height.Elementary Schools.Auditoriums, recreational buildings, arenas.Buildings for commercial office use or exhibition purposes.Retail stores and shopping centres.Laboratories.Simple hospitals, clinics, sanatoriums, polyvalent schools or high schools, universities and industrial buildings. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3413 54° Catégorie TV: a) Systèmes complets dc ventilation.Climatisation, avec conduits pour les systèmes à induction et/ou * tout A l'air».Refrigeration.pour tous les types de bâtiments.h) Plomberie et chauffage (à eau chaude, vapeur ou électricité) distribution électrique pour éclairage et force motrice, climatisation sans conduits.j ».«lit- tous les bâtiments suivants: Hotels et maisons d'appartements ayant jusqu'à et y compris cinq étages.Laboratoires de recherches.Hôpitaux, cliniques, sanatoriums, écoles ployvalentes ou secondaires, universités et bâtiments industriels.Édifices monumentaux, égli«es.musées.Bibliothèques et théâtres.Centrales thermiques.Coût des travaux de génie: ôô° a) Le coût des travaux de génie, sauf dans les cas prévus ci-après aux paragraphes 55 (b), (r).(il), (e), signifie le COÛt pour le propriétaire îles éléments suivants nécessaires pour parachever les travaux «le çénic et pour lesquels l'ingénieur rend des services professionnels, et/ou pour lesquels il est responsable.ii .Main-d'œuvre; ii Matériaux; iiii Ap|>arcils; iv) Dépenses; vi La partie des dépenses générales, îles frais généraux et du profit de l'entrepreneur général i|iii - applique aux travaux de génie.Cette partie doit être déterminée par une distribution au prorata dc ce montant, cn se basant sur la liste de coûts fournie par l'entrepreneur général.vi i Toutes les taxes dc vente fédérales, provinciale- et municipales, même si le propriétaire est exempt du paiement de certaines de ces taxes.b) Lorsque le propriétaire fournit des matériaux ou des appareils, de la main-d'œuvre ou ¦le- services qui sont incorporés dans les travaux de génie, il faut inclure dans le coût total desdits travaux la valeur réelle au prix du marché des matériaux ou des appareils comme s'ils avaient été achetés neufs ainsi que les salaires et les autres services au taux courant au moment où les travaux sont exécutés.cl Lorsque le propriétaire ou un entrepreneur, à la demande du propriétaire, fournit des matériaux ou des appareils usagés, il faut utiliser le prix réel du marché des matériaux ou des appareils comme s'ils avaient été achetés neufs, pour calculer le coût des travaux de génie.à) Aucune déduction ne doit être faite du coût des travaux dc génie par suite de toute réclamation par le propriétaire pour quelque cause que ce sort, ou de toute autre somme retenue sur les paiements dus à un tel entrepreneur.') Le coût des travaux dc génie ne comprend pas les honoraires professionnels ou le remboursement des dépenses payés ou dus par le propriétaire, non plus que le coût du terrain sur lequel les travaux s'exécutent.Tableau des honoraires minimaux à pourcentage: 56° Les honoraires minimaux à pourcentage pour le mode dc rémunération C sont donnés dans les tableaux suivants pour les quatre catégories de travaux.Les honoraires indiqués dans H e donne A de chaque tableau couvrent les Services professionnels décrits dans les seules divisions 3, 4, 5A et 5B de la première partie; quant aux honoraires apparaissant dans la colonne B de chaque tableau, ils couvrent les services professionnels décrits dans les seules divisions 3, 4, 5A et 5C de la première partie.54.Category IV: (a) Full Ventilation systems.Air Conditioning with ductwork for Induction and All-Air Systems.Refrigeration.for any and all types of buildings: (6) Plumbing and heating (hot water, steam or electrical) lighting and power distribution, air conditioning without ductwork.for all the following buildings: Hotels and Apartments up to and including 5 stories.Research laboratories.Hospitals, clinics, sanatoriums.Polyvalent schools or high schools, universities and industrial buildings.Monumental buildings, churches, museums, libraries and Theatres.Thermal Power Plants.Costs of Engineering Works 55.(a) The Cost of the Engineering Works, except as hereinafter provided in paragraphs 55 (6) (c) (rf) (c), shall mean the cost to the Owner of the following items necessary to complete the Engineering Works and for which the Engineer renders professional services, and/or for which he is responsible.(i) labour.(ii) Materials.(iii) Equipment.(iv) Expenses.(v) The share of the (iencral Contractor's general expenses, overhead and profit which is applicable to the Engineering Works.This share is to be determined by a prorata distribution of said amount based on the list of costs supplied by the (iencral Contractor.(vi) All Federal.Provincial and Municipal sales taxes, although the Owner may liavc special exemption from some of these (/)) Whenever the Owner furnishes material or equipment, labour or other service that is iucor|wratcd in the Engineering Works, the fair market value of the materials or equipment as though they were purcliased new and current prices of labour or other services when the work was executed, shall lie included in the total Cost of the Engineering Works.(c) Whenever used material or equipment is furnished by the Owner or by a contractor at the Owner's request, the fair market value of the materials or equipment as though they were purchased new.shall be used to compute the Cost of Engineering Works.(ur ce travail sont de 85% des honoraires pour les divisions 3 et 4, soit 85% de 70% pour chaque variante requise.f) Si le client désire reproduire la const ruction de travuux pour lesquels il a eu recours aux services dc l'ingénieur pour le projet original, une somme égale à 20% des honoraires indiqués à la colonne A du tableau précédent approprié doit être versée à l'ingénieur pour chaque réutilisation des plans et devis.Dc pins, |x>ur toute modification aux plans et devis entraînée par le clumge-nient (remplacement, l'ingénieur devra être rémunéré selon la méthode Per Diem ou la méthode du salaire.Pour chaque répétition des travaux, le coût des services durant la construction décrits aux sulxlivisions 5A et 5B, est dc 30% des valeurs indiquées à la colonne A du tableau précité, sauf dans les conditions expliquées nu paragraphe c) ci-haut, alors que ce pourcentage est dc 40%.62\" Modifications aux traraur projetés a) Quand l'engagement dc l'ingénieur prévoit sa rémunération par la méthode du pourcentage, les modifications aux ouvrages projetés demandées par le client imposent du travail supplémentaire ù l'ingénieur ou rendent inutile une partie du travail déjà accompli.Ces modifications peuvent réduire, augmenter ou modifier l'étendue et le programme des travaux déjà approuvés, ou les « plans et devis préliminaires » déjà approuvés, ou les « plans et devis définitifs » déjà approuvés.61.Further Conditions of the Percentage Bask) (a) The Engineer shall be reimbursed for the \"Defined Expenses\" clause 03.which are not included as jiart of the percentage fees indicated in the above tables.The Engineer shall supply the Client, as part of the |iercentagc fees, up In ten (10) copies of ull Specifications and drawings, printed on opaque paper, required for tender and construction purposes.Any additional copy as well as any negative type copy required -hail lie paid for by the Client at the cost of reproduction, except as provided for under Article 111 d), (5) The minimum fee for the services mentioned in Divisions 3 and 4 only shall be \"0% of the values listed in column A of the foregoing tables of Articles 57.58, 59 nnd 00.(r) When the Engineer is retained for the Services During Construction listed in sub-divisions 5A.5b.on work for which the plan- ami speculations have been prepared by other-, he shall l>e paid a minimum of 40% of the values listed in column A of the appropriate foregoing table of Articles 57.58, 59 and 0(1.(if) When the Engineer is retained for Services During Construction as listed in sub-divi-ioiis 5A, 5b and 5C.on work for which the plan- and Specifications have been prepared by other-, he shall Ik- paid according to the values listed in column B, less 00% of the corresponding \\«lue ill column A.of the appropriate foregoing table of Articles 57.58.59 and 60.(e) Where the Engineer lias completed the \"Filial Plans and Specifications\" on a percentage basis, and the Client desires the development of a new alternative design, the cost of such service shall lie computed on the basis of 85% of I be fee for the scrvhvs described in Divisions il and 4.i.e., 85% of 70%, for each additional alternative design.(/) If the Client desires to duplicate the construction of works, for which the Engineer has been retained for the original design, a charge of 20% of the values listed in column A ol the appropriate foregoing tabulated fee shall Is* made for each reuse of the plans and spécifications.Furthermore, for any modification t\" the plans and specifications due to a change in the location, the Engineer shall be remunerated on a Per Diem or Salary basis.For each duplication Of the works, the Services During Construction of sub-divisions 5A and 5B, shall lie rémunéra led at 30% of the values indicated in column \\ ol the table referred to above, except in the case explained in paragraph (c) of this article when this percentage shall be 40%.02.Modifications to Projected Works (a) When the Engineer has been engaged on a percentage basis, modifications to projected works called for by the Client impose additional work on the part of the Engineer or render useless some of the work already done.These modifications may reduce, extend or change the already approved scope and program or the already approved \"Preliminary Plans and Specifications\", or the already approved \"Final Plans and Specifications\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22.19G8.Vol.100, No.25 3419 Dans tous ces cas, l'ingénieur doit attirer l'attention du client sur la situation avant .l'entreprendre le travail additionnel et l'ingénieur doit être rémunéré en sus des honoraires à pour-ce ni age en vertu d'une entente spéciale à négocier pour déterminer la méthode appropriée de rémunération.b) Quand l'engagement de l'ingénieur prévoit sa rémunération par la méthode de pourcentage, les modifications demandées par le client durant la « phase de construction » lui imposent du travail supplémentaire pour la revision des plans cl devis, l'analyse et la négociation des prix des entrepreneurs pour ces revisions; ce travail supplémentaire doit être rémunéré scion la méthode Per Diem ou la méthode du snlaire.c) Quand l'engagement dc l'ingénieur prévoit sa rémunération par la méthode du pourcentage, et qu'il devient nécessaire pour l'ingénieur de refaire ses plans ou de les reviser pour des motifs sur lesquels il n'a aucun contrôle, ou si l'ingénieur doit encourir des frais ou faire du travail par suite du défaut ou de l'insolvabilité du client, ou d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant, ou par suite de la suspension des travaux ou de dommages causés aux travaux cn cours pir le feu OU d'autres causes, l'ingénieur doit recevoir une rémunération équitable pour tout ce travail supplémentaire scion la méthode Per Diem ou la méthode du salaire, plus tous ses déboursés.Dans tous ces cas, l'ingénieur doit attirer l'attention du client sur la situation avant d'entreprendre du travail supplémentaire et iloit conserver le détail des coûts cn un dossier distinct.Conditions générales relatives aux modes de rémunération A, B et C Dépenses définies (13° Les « dépenses définies » mentionnées aux modes de rémunération A, B et C sont celles qui suivent: a) Dépenses dc subsistance et de voyage des employés et patrons quand ils s'éloignent dc leur bureau principal pour vaquer à des tâches concernant le projet./') Dépenses attestées de communications comme les appels téléphoniques interurliains, les appareils téléphoniques au chantier, les frais de télétype, de télégraphe, dc poste et de livraison exprès.r) Le coût des services extérieurs comme les essais et les rapports sur les sols et les matériaux; les inspections, les services légaux, comptables, slénographiques ou de vérification spéciaux; et tout autre travail pour lequel il est nécessaire de faire appel aux services d'autres personnes ou d'autres firmes.'/) Les coûts attestés de reproduction comme les bleus, les photostats, la miméographie, l'impression, etc.sauf dispositions contraires dans le présent tarif.e) Pour les services en résidence, le coût de fourniture et d'entretien des installations de bureau sur le chantier et les dépenses découlant des risques spéciaux encourus.Les dépenses, de voyage, de subsistance et de déménagement des familles du personnel, sujet à l'assentiment du client.Coopération 64° Le client doit fournir à l'ingénieur les plans et les renseignements suivants sauf lorsque le client a spécifiquement demandé à l'ingénieur de fournir certains de ceux-ci comme partie de ses services, en vertu de la division 2.In any such case, the situation shall be called to the attention of the Client prior to starting the additional work and the Engineer shall be remunerated over and above the percentage fee according to a special agreement to lie reached on the appropriate method of remuneration.(b) When the Engineer has liecn engaged on a percentage basis, modifications called for by the Client during the \"Construction phase\" impose on the Engineer additional work for revisions to plans and specifications, for analysis and negotiations of contractors' prices on these revisions; this additional work shall be remunerated on the Per Diem or Salary Basis.(e.) When the Engineer has been engaged on a percentage basis, if it should become necessary for the Engineer to redraw the plans or to make revisions for reasons over which he has no control, or if the Engineer is put to labour and expense by the delinquency or insolvency of the Client or of a contractor or sub-contractor, or as a result of suspension of work or damage to the work in progress by lire or otherwise, the Engineer shall be equitably paid for such extra work on the Per Diem or Salary Basis, plus any out-of-pocket expenses.In any such case, the situation shall he called to the attention of the Client prior to starting the additional work and separate cost records shall lie kept by the Engineer.General ('auditions I'ertaiiiimj to Schedules A, Band G Defined Expenses 63.The \"Defined Expenses\" referred to in Schedules A.B and C arc as follows: (a) Living and travelling expenses of employees and principals when away from the home office on business connected with the project.(/») Identifiable communication expenses such as long distance telephones, costs of job telephone, teletype, telegraph.|K>stngc and express charges.(c) Cost of outside services such as soil and material tests and reports; special inspections and special legal, accounting, stenographic or audit services, and other work for which it is necessary to use the services of other persons or firms.(e granted a credit, according to an examination taken before an Examination Hoard.However, the six (6) month credit shall be granted only when the apprentice will have reached his fourth year of apprenticeship. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, So.25 3423 d) Après avoir obtenu son carnet, l'apprenti ° Le iwragraphe « c » dc l'article 41 est remplacé par le suivant : « r) carreleur et poseur de revêtement souple cl poseur de carrelages de matériau coni|X)sitc où il peut y avoir un apprenti pour chaque ouvrier qualifié, sur chaque chantier, devant Ionjours aider l'ouvrier cpialifié.7° Dans rémunération des métiers apparaissant à l'article 43 (Durée de l'apprentissage), les Dots « linoléum, muroléum » sont remplacés pir les mots « revêtement souple ».S\" L'item « Poseur «le lattis métallique .3 années apparaissant à l'article 43 est remplacé par l'item «Poseur dc lattis métallique .4 années ».'¦^ L'article 43-B suivant est ajouté au Titre Quatrième (Apprentissage, Service de Formation): ¦13-B.Poseurs de lull is métalliques: ¦n Admission: Avant d'être accepté officiellement à l'apprentissage, tout candidat n'ayant aucune expérience du métier doit se soumettre préalablement aux procédures de sélection, subir avec succès les tests d'aptitudes particuliers établi- |»ar le Centre d'apprentissage et suivre un cours obligatoire dc pas moins de six (6) mois audit Centre d'apprentissage au début duquel une période de probation d'un (1) mois doit être complétée selon les normes de satisfaction établies.' e n'est qu'à la suite de cette procédure que le < 'entre d'apprentissage pourra recommander rémission de la carte (l'apprentissage de première (Ire) année audit candidat à qui la durée du cours sera créditée; b) Taux dc salaire: lie année.50% du compagnon 2e année.70% du compagnon \u2022le année.85% du compagnon 4c année.90% du compagnon c) Examen de classification: i.À la fin de chaque «le ses première, deuxième, troisième et quatrième années d'apprentis-sa e.le cas échéant, tout apprenti doit se soumettre à un examen devant le bureau d'examinateurs du Comité conjoint pour les poseurs de (d) After having obtained his booklet, the apprentice shall report to the Apprenticeship Centre six (6) months later for the examination allowing the change of the booklet and of classification according to the degree of skill and to the experience acquired ) Wage rate: 1st year.50% of journeyman's rate 2nd year.70% of journeyman's rate 3rd year.85% of journeyman's rate 4th year.90% of journeyman's rate (c) Classification examination: (i) At the end of each of the first, second, third and fourth years of apprenticeship, as the case may be, all apprentices shall lie examined by the metal lathers' Board of Examiners.This examination will take place at the Ap- 3424 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 lattis métalliques.Cet examen a lieu au Centre d'apprentissage, 5295 rue Parllienais, Montréal, au jour et à l'heure spécifiés par le Centre; ii.Le bureau des examinateurs est seul liabi-lité à émettre de nouvelles cartes «l'apprentissage, à pouvoir accorder des crédits proportionnels à l'expérience théorique et pratique acquise et aux résultats obtenus à l'examen, refuser une promotion non justifiée par les résultats dudit examen.iii.Tout candidat, détenteur d'un carnet d'apprentissage à la date d'entrée en vigueur du présent décret dc modification, se verra à la date «l'expiration «le ce carnet et à la suite «le l'examen prescrit, attribuer une classification non moindre que celle indiquée au carnet échu.» 10° La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe « i » dc l'article 96: « y inclus le remboursement «le dépenses raisonnables encourues par le comité conjoint dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu des paragraphes «a » et « c » de l'article 69 des présentes.» 11° Les mots «sujet à la Loi des régimes supplémentaires > sont ajoutés après les mots « Sous-Comité dc Sécurité Sociale » apparaissant à l'article 111.12° Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 115: « Dans les «ras où les contributions «l'employé ont été déduites par l'employeur et que ce dernier a négligé «le les remettre au comité conjoint, le sous-comité de sécurité sociale peut déclarer que l'admissibilité au bi'néfice d'assurance-vic d'un employé OU ancien employé décédé soit calculée en tenant compte des contributions déduites mais non remises, si Ici lit sous-comité est convaincu que l'employeur a déduit ces sommes d'argent, «le la paie «le l'employé et que le fait que lesdites sommes d'argent n'ont pas été remises au comité conjoint n'est aucunement imputable ù l'employé ou l'ancien employé décédé.» Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 25016-o D.Tanouay.Arrc-té en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1706 Québec, le 6 juin 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications nu décret relatif à l'industrie du verre dans la région de Montréal.Attendu que, conformément aux dispositions de la Loi «les décrets «le convention collective (Statuts Refondus du Quélicc 1964, chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire pir le décret numéro 2051 du 28 octobre 1964 et amemlement, relatif à l'industrie «lu verre dans la région dc Montréal, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre A l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret; Attendu que ladite requête a été publiée dans la Gazette officielle de Québec, édition «lu 16 mars 1968; Attendu que l'objection formulée a été appréciée conformément à la Loi; Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: prcntieeship Centre, 5295 Parthcnais Street.Montreal, on the day and at the time specified by I be ' 'entre; (ii) the Hoard of Examiners alone is qualified to issue new apprenticeship cards, to grant credits proportionate to the theoretical and practical experience acquired, anil according to the results obtained in the examination ami to deny a promotion not justified by the results of the said examination; (iii) every candidate who holds an apprentice-ship booklet on the effective date of the present amendment decree shall, at the expiration ol this booklet and following the prescribed examinât ion.receive a classification at least equal lo that indicated in the expired liooklet.\" 10.The following sentence is added to the end of subsection \"i\", article 96: \"including the reimbursement of reasonable expenses incurred by the Joint Committee in the performance of its duties, as per subsections (a) and (c) of article 09 hereof.11.In article 111.the words \"subject to ihe Supplemental Pension Plans Act\" are added after the words \"social security sub-commit tie\".12.The following paragraph is added to article 115: \"When employee contributions have been deducted by the employer and the latter lias failed lo forward them to the Joint Committee, the social security subcommittee may authorize that the eligibility of an employee or deceased former employee to life insurance benefits be computed while taking into account the contributions deducted and not forwardcil.provided the said sub-coinni'ttec is certain that the employer has deducted such amounts from Ihe employee's wages und that the employee or deceased former employer is not responsible for the fact that the contributions have not been forwarded to the Joint Committee\" D.Tanguay, 25016-0 Acting Clerk of the Executive Council-Order in Council Executive Council Chamber Number 1706 Québec, June 6, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning amendments to the decree res-pecting the Flat Glass Industry in the Montreal Region.Whereas, pursuant lo the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Flat Glass bidustry in the Montreal region (made binding by Decree number 2051 of October 28, 1964.as amendeil) have petitioned the Minister of Labour to submit the following amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision ; Whereas the petition was published in the Quebec Official Gazette of March 16,1968; Whereas, in compliance with the Act, the objection brought forth was duly considered; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3425 Oca ledit décret, numéro 2051, soit modifié That said Decree number 2051 be amended comme suit: as follows: Les articles III, IV, V, VI, VIT et Vm sont Articles III, IV, V, VI, VII and VIII are remplacés par les suivants: superseded by the following: « Article III \"Article III 3.01 Classification des emplois et salaires: La 3.01 Occupational classification and wage rates: i la ->i lication des emplois des employés et les taux The occupational classification and corresponding minima qui s'y appliquent sont les suivants: minimum wage rate of employees are as follows: / nor.I mai 1968 11)69 Xoi: 1 Mai/ 1 1968 1060 Mouleur mécanicien \u2014 Setter mechanic: Classe A \u2014Class A.83.15 83.25 83.40 Classe B \u2014 Class B.2.79 2.86 2.96 Monteur compagnon \u2014 Setter journeyman: ( lasse A \u2014 Class A.3.15 3.25 3.40 Classe B \u2014 Class B.2.50 2.57 2.67 \\b.pur de verre et de panneaux à tympan \u2014 Setter, glass and spandrel 'Tlassc A - Class A.2.75 2.85 3.00 ( lasse B \u2014 Class B.2.33 2.40 2.50 Mouleur à l'intérieur Setter, inside: Classe A \u2014Class A.2.20 2.25 2.35 Classe B - Class B.2.00 2.05 2.10 Hbcaulcur-graveur \u2014 Bevellcr-engraver: ( lasse A \u2014 Class A.2.40 2.45 2.55 Classe B \u2014Class B.2.18 2.23 2.28 ( oiiihiir île glace dc vitrage \u2014 Cutter, plate glass: Classe A \u2014 Class A.2.37 2.42 2.52 Classe B \u2014Class B.2.15 2.20 2.25 Ktaineur \u2014 Silvcrer: Classe A - Class A.2.32 2.37 2.47 Classe B \u2014 Class B.2.00 2.05 2.10 Coupeur de verre à vitres \u2014 Cutter, window glass: Classe A \u2014Class A.2.30 2.35 2.45 ( \"lasse B \u2014 Class B.2.10 2.15 2.20 Poseur «le glace d'automobile \u2014 Setter, automobile glass Classe A \u2014 Class A.2.25 2.30 2.40 Classe B \u2014Class B.2.05 2.10 2.15 Biseauteur \u2014 Bcveller: Classe A-Class A.2.37 2.42 2.52 ClassB \u2014Class B.2.15 2.20 2.25 Coupeur et vitrier de plomb \u2014 Cutter and glazier, lead: Classe A-Class A.2.15 2.20 2.30 ( lasse B \u2014 Class B.2.00 2.05 2.10 Conducteur de machine automatique à biseauter et à polir-Oiicrator, automatic bevelling and polishing machine: Classe A \u2014Class A.2.20 2.25 2.35 Classe B \u2014 Class B.2.00 2.05 2.10 Polisseur d'égratignures-vérificateur \u2014 Polisher-examiner, scratches: Classe A-Class A.2.20 2.25 2.35 Classe B - Class B.2.00 2.05 2.10 Polisseur - appareil à disque horizontal ou vertical de feutre ou de liège \u2014 Polisher and buffer (horizontal or vertical, felt or cork wheel): Classe A\u2014Class A.2.20 2.25 2.35 Classe B-Class B.2.10 2.15 2.20 Polisseur de machine à courroie \u2014 Belt worker: Classe A \u2014 Class A.2.19 2.24 2.34 Classe B \u2014 Class B.1.90 1.95 2.00 Conducteur d'équipement mobile de chargement et de déchargement \u2014 1 Iperator, mobile loading and unloading equipment: Classe A \u2014 Class A.2.10 2.15 2.25 Classe B-Class B.1.00 1.96 2.00 3426 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 1 non.1 mai 1968 1969 Nov.1 Mai/ ! 1968 1969 Emliallcur \u2014Packer.12.00 J2.05 $2.10 Vitrier \u2014Glazier.2.15 2.20 2.25 Encadreur \u2014 Frumvr and sasher: Masculin \u2014Maie.1.78 1.81 1.91 Féminin \u2014 Female.1-61 1.66 1.70 Peintre au pistolet - Spray painter.2.10 2.15 2.20 Traceur au sable et givreur\u2014 Draughtsman on sandblasted and chipped glass.2.10 2.15 2.20 Expéditeur \u2014 Shipping dispatcher.2.05 2.10 2 15 Aide général\u2014(iencral helper.1.90 1.95 2.IK) Chauffeur de camion \u2014 Truck driver.2.10 2.15 2.20 3.02 L'augmentation minimale à laquelle un 3.02 The minimum increase to which a employé permanent a droit à l'une ou à l'autre regular employee shall be entitled on any of the des dates d'augmentation stipulées à la clause dates of increase stipulated in subsection 3.01 3.01 des présentes, doit être déterminée selon above shall be determined according to Ihe l'emploi qu'il aura à la date «l'augmentation classification which the employee shall have on applicable; cette augmentation minimale ne doit the applicable date.The minimum increase shall pas être inférieure, selon le cas, aux montants not be inferior, as the case may be, to the amount stipules ci-dessous: stipulated hereunder: 1.S'il est monteur mécanicien, classe A, mon- 1.If he is a setter-mechanic class \"A\", setter-teur compagnon, classe « A » ou monteur de journeyman class \"A\", or setter, glass and verre et de panneaux ù tympan, classe « A »: spandrel panel class \"A\": a) À la date de mise en vigueur du présent (a) 25ç an hour on the effective date of this décret de modification 25é l'heure; amendment decree; b) le 1er novembre 1968, 10c l'heure; (b) 10c an hour on November 1, 1968; c) le 1er mai 1969, 15é l'heure.(c) 15** an hour on May 1, 1969.2.S'il est monteur mécanicien, classe « B », 2.If he is a setter-michanic class \"B\", setter-monteur compagnon, classe « B », ou monteur journeyman class \"B\", or setter, glass and de verre et dc panneaux ù tympan, classe « B »: spandrel panel class \"B\": a) À la date de mise en vigueur du présent (a) 18c an hour on the effective date of this décret de modification, 18é l'heure; amendment decree; b) le 1er novembre 1968.7é l'heure; (b) 7é an hour on November 1, 1968; c) le 1er mai 1969, 10e l'heure.(c) 10é an hour on May 1, 1969.3.S'il est monteur à l'intérieur, classe « A », 3.If he is a setter inside class \"A\", beveller-biseauteur-graveur, classe «A», coupeur dc engraver class \"A\", plate glass cutter class \"A\", glace dc vitrage, classe « A », étameur, classe silverer class \"A\", window glass cutter class \"A\", «  », coupeur de verre a vitres, classe « A », automobile glass setter class \"A\", beveller class poseur de glace d'automobile, classe « A », biseau- \"A\", lead cutter and glazier class \"A\", automatic tcur, classe « A », coupeur et vitrier de plomb, bevelling and polishing machine operator class classe « A », conducteur de machine automatique \"A\", scratch polisher-examiner class \"A\", polit biseauter et ù polir, classe « A », ou polisseur isher and buffer (horizontal or vertical, felt or d'égratignures, vérificateur, classe « A », polisseur cork wheel) class \"A\", belt worker class \"A\", appareil à disque horizontal ou vertical de feutre operator of mobile equipment for loading and ou de liège, classe «A », polisseur de machine à, unloading Class \"A\", or framer and sasher courroie, classe «A», conducteur d'équipement (male or female) : mobile pour le chargement et le déchargement, classe « A », ou encadreur (masculin ou féminin): a) A la date de mise en vigueur du présent dé- (a) 15é an hour on the effective date of this cret d'amendement, 15é l'heure; amendment decree; b) le 1er novembre 1968, 5é l'heure; (b) 5é an hour on November 1, 1968; c) le 1er mai 1969, 10(1 l'heure.(c) lOjé an hour on May 1, 1969.4.S'il est monteur à l'intérieur, classe « B », 4.If he is a setter inside class \"B\", beveller-biseauteur-graveur, classe « B », coupeur de glace engraver class \"B\", plate glass cutter class \"B\", de vitrage, classe « B », étameur, classe « B », silverer class \"B\", window glass cutler class \"b , coupeur de verre à vitres, classe « B », poseur automobile glass setter class \"B\", beveller class de glace d'automobile, classe « B », biseauteur, \"B\", lead cutter and glazier class \"B\", automatic classe « B », coupeur et vitrier de plomb, classe bevelling and polishing machine operator class « B », conducteur de machine automatique à \"B\", scratch polisher-examiner class \"B\", pol-biseauter et à polir, classe « B », polisseur d'égra- isher and buffer (horizontal or vertical, felt or tignures-vérificateur, classe « B », polisseur, appa- cork wheel) class \"B\", belt worker class \"b\".reil à disque horizontal ou vertical de feutre ou de operator of mobile equipment for loading and liège, classe « B », polisseur de machine à courroie, unloading class \"B\", packer, glazier, spiny classe « B », conducteur d'équipement pour le painter, draughtsman on sandblasted or chippd chargement et le déchargement, classe « B », glass, shipping dispatcher, general helper, or emballeur, vitrier, peintre au pistolet, traceur truck driver: au sable et givreur, expéditeur, aide général ou chauffeur de camion: a) À la date de mise en vigueur du présent (a) 15é an hour on the effective date of this décret de modification, 15é l'heure; amendment decree; b) le 1er novembre 1968, 5é l'heure; (b) 5é an hour on November 1, 1968; c) le 1er mai 1969,5é l'heure.(c) 5f! an hour on May 1, 1969. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3427 3.03 Bulletin de paie: Le salaire doit être payé en espèces le vendredi à midi ou par chèque au plus lard le jeudi, dans la semaine de paie habituel1\" de l'employeur.[/employeur doit remettre au salarié, avec chaque paye, un état contenant les mentions suivantes: a) les nom et prénoms du salarié; h le nombre d'heures normales; c) le nombre d'heures supplémentaires; d) le taux horaire du salaire; , le nomtant du salaire brut; /' la nature et le-montant des retenues opérées; g) le montant du salaire net.Article IV Attributions des classes aux employés 4.0l «) Tous les employés qui, le 4 janvier 1968, étaient classés dans l'un ou l'autre des emplois pour lesquels les règlements du comité paritaire rendent obligatoire un ccrtificatde qualification et qui étaient classés par leur employeur dans la classe «A» ou dans la classe «B» devront se présenter à l'examen du bureau des examinateurs du comité paritaire pour se classer < A .s'ils ne l'ont déjà fait.S'ils réussissent l'examen, le bureau des examinateurs du comité paritaire émettra un certificat classe « A ».Sinon, ils pourront, si leur examen le justifie, recevoir un certificat classe « B ».Dans ce cas, le bureau des examinateurs du comité paritaire déterminera en même temps le nombre d'années d'apprentissage qui leur sont créditées.Aucun autre certificat classe « B », dans ces classifications ne devra être émis à l'avenir.Si ces employés ne réussissent pas à l'examen à se classer « B » mais, si de l'avis du comité paritaire ils sont acceptables comme apprentis, ils >eront inscrits comme tels et le bureau des examinateurs du comité paritaire déterminera alors le nombre d'années d'apprentissage qui leur sont créditées, s'il y a lieu.6) Les employés qui, le 4 janvier 19C8, étaient classés dans les emplois pour lesquels un certificat de qualification n'existait pas et qui se présenteront à l'examen dans les trois (3) mois des présentes, seront, soit classés « A » par le bureau des examinateurs avec certificat de qualification s'ils réussissent l'examen, soit, advenant un échec, classés apprentis, s'ils sont par ailleurs acceptables au bureau des examinateurs et, dans ce cas, le bureau des examinateurs pourra, s'il y a lieu, leur attribuer un crédit d'apprentissage.c) À compter de la qualification de la façon susdite par le bureau des examinateurs, l'employé travaillant dans Pun des emplois en question, recevra au moins le taux de salaire de la classe qui lui est attribuée (classe « A », classe « B » ou apprenti).4.02 Dans le cas des emplois pour lesquels aucun règlement de certificat de qualification n'est prévu: 1.Ceux qui auront travaillé pendant une période d'au moins quatre (4) ans comme em-l'I' '.' es classe « B » dans le même emploi, seront eusses « A » ; 2.ceux qui auront atteint un niveau de conijiétence leur permettant de se charger com-plèl nient du travail exigé dans cet emploi Particulier seront classés « A »; 3.Tout employé qui n'est pas classé « A » dans une catégorie dans laquelle il travaille sera classé « B » ; 3.03 Earnings statement: Wages shall be paid in cash on Friday noon, or by cheque no later than Thursday of the employer's usual pay week.With each pay, the employer shall provide the employee with a statement listing: (a) the employee's family and given names; (b) the number of standard hours of work; (c) the number of overtime hours worked; (rf) hourly wage rate; (e) the gross amount of earnings; (/) the type and amounts of deductions made; (g) the take-home pay.Article IV Assigning classes to employees 4.01 (fl) All employees who on January 4, 1968, belonged to one of the occupations for which the by-laws of the Joint Committee require a competency card and who were classed either \"A\" or \"B\" by their employer, are required to take an examination of the Joint Committee's Board of Examiners to be classified \"A\", unless they have already taken such examination.If they succeed, the Joint Committee's Board of Examiners shall issue them a class \"A\" card.If they fail, the Joint Committee may issue a class \"B\" card if the examination so warrants.In such case, the Joint Committee's Board of Examiners shall at the same lime determine the number of years of apprenticeship they are to be credited with.No other class \"B\" card in these classifications shall be issued in the future.Should those employees fail to qualify for class \"B\" and if the Joint Committee finds them acceptable as apprentices, they shall be registered as such.The Joint Committee's Bo ird of Examiners shall then determine the number of years of apprenticeship they are to be credited with, if they arc entitled thereto.(i) Employees who on January 4, 1968, were not classified in an occupation requiring a competency card and who take an examination within three (3) months of these presents, shall either be classed \"A\" by the Board of Examiners with competency card if they succeed or, should they fail, be classed as apprentices by the Board of Examiners if the latter judges them acceptable.In such case, the Board of Examiners may, if they are entitled thereto, grant an apprenticeship credit.(c) Once classified as aforesaid by the Board of Examiners, an employee working in one of the occupations concerned, shall receive the wage rate of the class assigned to him (class \"A\", class \"B\" or apprentice).4.02 In the ease of occupations for which no competency card regulations arc provided, employees shall be classified \"A\" as follows: 1.if they have worked for at least four (4) years as a class \"B\" employee in the same classification; 2.if they have reached a level of competency enabling them to take complete charge of the work required in that particular classification; 3.employees who are not classified \"A\" withim their classification shall be classified \"B\"; 3428 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 4.Si un employeur refuse tic classer un employé « A », il sera loisible à ce dernier de faire uppel au comité paritaire.Après un avis écrit de dix (10) jours à l'employeur, le comité nommera alors un bureau d'examinateurs chargé de faire passer un examen à l'employé et de déterminer la classe (« A » ou « 11 ») de ce dernier.Article V Description des emplois Aux fins du présent décret, le genre de travail et les devoirs des employés île la classe « A » sont comme suit: 5.01 Monteur de verre et dc panneaux à tympan: Cet employé doit cire qualifié j>our se charger dtl montage, du démontage, de la taille, dc la préparation ou de la manutention de verre «l'art, dc verre prismatique, de verre à vitres, «le verre de plomb, «le verre biseauté, de verre dc sûreté, «le glace dc vitrage, de miroirs de toutes sortes, dc verre armé, de verre strié, «le verre «lépdi, de verre coloré, «le verre coulé, de verre ouvré, de vilrolitc, du verre de carrare, de panneaux à tympan et de toutes autres sortes de verre opaque, «le glaces à tableaux (chalkboard), de verre de construction, de verre trempe et feuilleté et «le toutes espèces d'éléments «le verre isolant, «le tous plastiques ou «le tous matériaux connexes pour remplacer le verre, ces produits devant être installés avec des ciments à verre, du Thiokol, «lu néoprène, ou toutes autres espèces de scellants ou devant être montés ou j.)osés dans toutes espèces de mastics, de moulures, «le caoutchouc, «le plomb et «le toutes espèces d'adhésifs sur lxjis, sur maçonnerie, sur fer, sur aluminium ou dans des cadres dc châssis métalliques, des lucarnes faîtières, des portes, de cadres, ¦ les montres-murales, des montres-comptoirs, des buffets, des cloisons et des aménagements.Il «loit aussi être qualifié pour se charger dc l'installation, temporaire ou permanente des matériaux précités, que ce soit à l'atelier ou sur les chantiers, sur ou pour tout édifice qu'on construit, répare, transforme ou modifie.5.02 Monteur: Cet employé doit être qualifié POUT se charger complètement de l'installation, lorsqu'elle se rapporte aux opérations «le l'industrie du verre, «le tous métaux roulés, refoulés ou fabriqués, ou de tous matériaux les remplaçant ou les renforcissant; de tulies de métal, de meneaux horizontaux OU verticaux, de parement de métal ou autre matériau, de garnitures, de fasces, de moulures, de panneaux «le porcelaines, de porcelaines artlutecturales, de panneaux ou «le dômes de plastique ou de verre ou de matériaux connexes, y compris tous les matériaux utilisés dans l'installation et.le moulage de devantures de boutiques, de portes mobiles ou fixes, dc cadres de jwrtes, de chassis mobiles ou fixes, de cadres de ch&ssis, «le lucarnes faîtières, d'enceintes de baignoires et dc contre-fenêtres où le verre devient une partie intégrale du produit fini.Cet employé doit «le plus être capable dc lire et d'interpréter les plans relatifs à ces installations.5.03 Monteur mécanicien: En plus de pouvoir exécuter tout le travail d'un monteur décrit ci-dessus, cet employé doit aussi être capable dc se charger du montage dc tous murs-rideaux «le quelque grandeur que ce soit.Cet employé est qualifié pour lire et interpréter les plans relatifs à toutes les installations décrites ci-dessus.4.if an employer refuses to classify an employee in class \"A\", the employee shall be entitled to appeal to the Joint Committee.After a ten-day written notice to the employer, the Joint (.mittee shall appoint a Board of E xamiticr- to examine the employee and determine whether he belongs to class \"A\" or class \"B\".Article V Occupational descriptions For the purjxise of this decree, the type of work and the duties to be performed by class \"A\" employees are as follows: 5.01 Setter, glass and spandrel panel: Such employee must be qualified to take charge of the setting, removal, cutting, preparation or handling or art glass, prism, glass, window glass, leader glass bevelled glass, safety glass, plate glass, mirrors of all types, wired glass, ribbed glass, ground glass, coloured glass, figured gluss, Vitrohte, Carrara, spandrel panels and all other types of opaque glass; glass chalkboards, structural glass, tempered and laminated glass ami all other types of insulating glass units; all plastics or related materials when used in place of glass, the same to be installed with the use of glass cements.Thiokol, Neoprene or all other type- of sealants, to be set or glazed with putty, moulding, rubber, leail and all typ's of adhesives in wood, masonry, iron, aluminium or sheet-metal sashes, skylights, doors, frames wall cases, show-eases, sideboards, partitions and fixtures.He must also be qualified to take charge of the installation, cither temporary or permanent, of the aforementioned materials, be it in the shop or on the job-site, on or for any building undergoing repairs, remodelling, alteration of construction.5.02 Setter-journeyman: Such employee must be qualified to lake complete charge of the installation (when related to the operations of the glass industry) of: all extruded, rolled or fabricated metals, or any materials replacing or reinforcing the same; metal tubes, mullioiis, facings made of metal or other materials, muut in-, fascia trims, mouldings, porcelain panels, architectural porcelain, glass or plastic panel- or domes and related materials, including all those used in the installation and erection of storefronts, doors (moving or fixed), door frame-, windows (moving or fixed), window Irani' -\u2022 skylights, bathtub enclosures and sashes wis re glass becomes an iucgral part of the finished product.Such employee must also be capable of reading and interpreting the plans relating to such installations.5.03 Setter mechanic: Besides being capable ol performing all the work done by a setter-journeyman as detailed in the foregoing subsection, such employee is also expected to take cliargc of the erection of any size curtain wall.He must also be able to read and interpret the plans covering all the installations described above. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3429 5.04 Monteur à l'intérieur: Cet employé doit (tre qualifié pour se charger dc la taille, de l'assemblage, de la préparation (lorsque ces opérations se rapportent à l'industrie du verre) île toits métaux roulés, refoulés ou fabriqués, de tous matériaux les remplaçant ou les renfor-fissiilit, «le tubes dc métal, dc meneaux verticaux cl horizontaux, de parement dc métal ou autre matériau, dc garnitures, de fasces, de moulures, île panneaux «le porcelaine, de porcelaines architecturales, dc panneaux de verre ou de plastique, de lucarnes faîtières, dc portes d'entrée et «le vestibules, de portes de montres-comptoirs, de portes mobiles ou fixes et de cadres de portes, de fenêtres mobiles ou fixes et d'assemblage de cadres «le fenêtre et d'enceintes de baignoires.â uô llixeauteur-grarcur: Cet employé doit être qualifié pour se charger des opérations de biseautage de toutes sortes et en toutes largeurs, du polissage des égratignurcs, «le la taille et «le la gravure sur verre plat, de tous motifs et dessins à la meule ou autrement, «lu perçage de trous, de lu conduite «les machines à courroie, du nieulage et du polissage et aussi du fonctionnement et «le l'entretien efficace «le tout équipement, de toutes machines et de tous outils pour ces opérations, 5.06 Coupeur de glace de rit rage: Cet employé doit élre qualifié pmr se charger «le la taille de la glace de vitrage, du verre à vitres, clair ou argenté, du verre ouvré, roulé OU broché, du vilrolite.du verre dc carrare, du verre feuilleté, du verre de sécurité et du verre cannelé, quelles que -oient l'épaisseur et la forme de ces verres, tout en rencontrant des normes élevées d'efficacité et d'économie dans ces coupes.5.117 Coupeur de verre à vitrei: Cet employé doit être qualifié pour se charger de la taille de verre à vil tes, clair ou argenté, du verre ouvré, du verre roulé, du verre coloré et du verre coloré et ouvré, quelles que soient l'épaisseur et la forme de ces verres.Il doit de plus être capable d'exécuter des coupes en série (production cutting) avec ou sans l'aide de machines ou d'outils spéciaux ou des deux à la fois.5.08 Étameur: Cet employé doit connaître à fond les diverses caractéristiques d etamage des verres et être qualifié pour se charger des procédés île lavage, de décapage et de préparation de ces verres; de la préparation efficace et économique des solutions d'etamage qu'ils appliqueront eux-mêmes et aussi de la peinture, du nettoyage d de remballage desdits verres.5.00 Poseur de glace d'automobile: Cet employé doit ''Ire qualifie pour se charger de la coupe et de l'installation de toutes sortes de glaces d'automobile-et autres véhicules, du fonctionnement et de l'entretien efficace de tout équipement, de toutes machines et de tous outils requis pour ces opérations.5.10 Biseauteur: Cet employé doit être qualifié pour se charger des opérations de biseautage de toutes sortes et en toutes largeurs, du polissage des égratignurcs, des entailles à l'onglet, du per-eagi de trous, de l'entretien et du fonctionnement de tout équipement, dc toutes machines et de tous outils pour ces opérations et du fonctionnement de machines à courroie pour meuler et polir.5.11 Coupeur et vitrier de plomb: Cet employé doit être qualifié pour se charger de la préparation «le tous motifs et dessins et de la taille du Wrre à vitre, du verre coloré, du verre ouvré, du verre ouvré et coulé et des métaux dc toutes grandeurs et de toutes formes selon les exigences de leur métier.5.04 Setter, inside: Such employee must be qualified to take charge of the cutting, assembling and preparation (when minted to the glass industry) of: all extruded, rolled or fabricated metals or any materials replacing or reinforcing the same; metal tubes, mullions, facings made of metal or other materials, niuntins.fascia trim, mouldings, porcelain panels, architectural porcelain, plastic or glass panels, skylights, entrance doors and vestibules, show-case doors, doors (moving or fixed) and door frames, window frame assemblies, vented or fixed windows and bathtub enclosures.5.05 Bereller-cngrarer: Such employee must be qualified to take charge of all bevelling, in all tyjies and widths; scratch-polishing, flat glass wheel-cutting (floral or others), mitre-cutting, engraving, hole-drilling; the operation of belt machines, of grinding and polishing nnd the proper operation and care of all equipment, machines and tools for these operations.5.06 Cutter, plate glass: Such employee must lie qualified to take charge of the cutting of plate glass, sheet and window glass (clear or silvered), figured glass (rolled or wired), vitrolitc, carrara, laminated and safety glass, corrugated glass, the saiil glass being of all thicknesses and shapes and the cutting thereof lo be of a high standard of efficiency and economy.5.07 Cutter, window glass: Such employee must be qualified to take charge of the cutting of window glass (clear or silvered), figured glass, rolled glass, coloured glass and figured coloured glass, the said glass being of all thicknesses and shapes.Such employees are also expected to tlo \"production cutting\" with or without the help of special machines or tools, or both.5.08 Silvcrcr: Such employee must be fully acquainted with the different silvering qualities of glass and be fully qualified to take charge of: the operation of washing, stripping and preparing the said glass; the efficient and economical preparation of silvering solutions for application by themselves, as well as the painting, cleaning and crating of the said glass.5.09 Automobile glass setter: Such employee must be qualified to take charge of: the cutting and installation of all types of glass to be used in automobiles and other vehicles; the proper operation, maintenance and care of all equipment, machines and tools for such operations.5.10 Beveller: Such employee must be qualified to take charge of: the operation of bevelling of all types and widths; scratch-polishing, mitre cutting, hole-drilling; the operation of belt machines for grinding and polishing and the operation and care of all equipment, machines and tools for these operations.5.11 Lead cutter and glazier: Such employee must be qualified to take charge of preparing all patterns and designs and the cutting of sheet an«l window glass, coloured glass, figured glass, figured rolled glass and metals in sizes and shapes as required by his trade. 3430 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin IMS, 100' année, n° 25 5.12 Conducteur dc machines automatiques à biseauter et à polir: Cet employé doit être qualifié pour se charger du fonctionnement de l'équipement, des machines et des outils utilisés dans le biseautage et le polissage automatique; il doit en bien connaître les mécanismes et pouvoir se charger de leur entretien.5.13 Polisseur à\"égratignurcs, vérificateur: Cet employé doit être qualifié pour déceler les égratignurcs et autres défauts, mineurs dans toutes espèces dc verres; il doit faire preuve d'un jugement sûr dans le choix des pièces qui peuvent être réparées efficacement et économiquement et pouvoir alors faire disparaître ces égratignures ou ces défauts ù l'aide de l'équipement, des machines ou des outils nécessaires.5.14 Polisseur, appareil à disque horizontal on vertical dc feutre ou de liège: Cet employé doit être qualifié pour assumer la conduite de l'équipement, des machines, des outils à polir ou à adoucir le verre; il doit aussi être capable dc conduire les machines à courroie et se charger dc leur entretien.5.15 Polisseur, machines à courroie: Cet employé doit être qualifié pour prendre charge du fonctionnement de tout équipement, de toutes machines et de tous outils à meulcr, à polir et à adoucir le verre, de même que les machines à courroie et de leurs accessoires et pour se charger dc leur entretien.5.16 Conducteur d'équipement mobile de.chargement et de déchargement: Cet employé doit être complètement quatifié pour conduire avec sécurité et entretenir efficacement l'équipement mobile, les machines et les outils utilisés pour charger et décharger tout matériel à l'intérieur de l'atelier ou à l'extérieur.5.17 Emballeur: Cet employé a comme occupation principale la fabrication de boites d'emballage en bois.Article VI Changement de classement 6.01 L'employeur peut exiger qu'un employé occupe temporairement un emploi qui n'est pas le sien, mais dans ce cas, il doit lui payer le taux de salaire de son emploi habituel.6.02 Lorsqu'un employé obtient un chargement dc classement, il doit toucher immédiatement le taux de son nouvel emploi.Article VII Taux supérieurs dc salaire 7.01 Quels que soient les taux dc salaire stipulés dans le présent décret, il ne doit cn résulter aucune diminution dans le taux de salaire d'un employé dont le taux actuel est supérieur au taux stipulé pour son emploi, tant et aussi longtemps qu'il demeure dans cet emploi.Article VIII Prime de chef d'équipe 5.01 Tout employé qui agit à l'extérieur à titre de chef d'une équipe de cinq (5) autres employés ou plus, a droit à une prime de 10e l'heure.8.02 Tout employé qui travaille sur un échafaudage volant fixé à un immeuble de trois étages ou plus au-dessus du sol, a droit à une prime de 15c- l'heure.8.03 Prime dc nuit: Tout salarié a droit à une prime dc 10e l'heure pour toute heure normale de travail fixée par l'employeur entre 19 h et 7 h du matin.5.12 Operator, automatic bevelling and polishing machine: Such employee must be qualified to take charge of the operation of equipment, machines and tools for automatic bevelling and polishing operations.He must master the mechanics thereof and take charge of their maintenance, 5.13 Scratch polisher, examiner: Such employee must be qualified to detect scratches and minor defects in all types of glass.He musl use sound judgment in the selection of such glass that can be repaired efficiently and economically and thus be able to remove said scratches or defects with the use of equipment, machines and tools therefor.5.14 Polisher and buffer (horizontal or vertical, felt or cork wheel): Such employee musl be qualified to take charge of the operation of equipment, machines and tools for polishing or bulling glass.He must also be qualified in Ihe operation of belt machines and be able to lake charge of the maintenance thereof.5.15 Belt worker: Such employee must he qualified to take charge of the operation of equip ment, machines and tools for grinding, polishing and bulling glass as well as licit machines, their components and take charge of the maintenance thereof.5.16 Operator, mobile loading and unloading equipment: Such employee shall be fully qualified in the safe operation and efficient maintenance of mobile equipment, machines ami tools for loading and unloading goods in or out of the premises.5.17 Packer: Such employee is mainly engaged in the fabrication of wooden boxes for crating purposes.Article VI Change of classification 6.01 The employer may have an employee work temporarily in a category to which he docs not belong.In such instance, bis wage rate shall be his regular rate.6.02 When a change is granted at an employee's request, he shall immediately be paid his liCW classification's rate Article VII Higher wage rates 7.01 Notwithstanding the wage rates stipulated herein, there shall be no decrease in the wage rate of any employee while he remains in the same occupation, should his actual wage rate be in excess of the wage rate stipulated for his occupation.Article VIII Premiums 8.01 Any employee acting as outside Icadhaud of five (5) or more employees shall be paid a lOé-pcr- hour premium.8.02 Any employee working on a swing-stage used on any building of 3 or more Boors above ground shall lie paid a premium of 15é per hour.8.03 S'ight-shipt premium: For all standard hours of work scheduled by the employer between 7:00 p.m.and 7:00 a.m., every employee shall be entitled to a lOé-per-hour premium. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968 Vol.100, No.25 3431 Article IX Jours fériés 0.O1 Lc premier jour de l'An, le vendredi saint, la Saint-Jean-Baptiste, le jour de la Confédération, la fête du Travail, le jour d'Action de grâce et le jour de Noël doivent être chômes et payés, à raison de neuf (9) heures par jour au taux normal, à condition que l'employé ait travaillé le jour ouvrable précédant le jour férié et le jour ouvrable suivant, sauf au cas d'absence dûment autorisée par l'employeur.0.02 Le jour férié doit être payé, quel que soil le jour où il tombe.Article X Congés dc deuil 10.01 Tout employé dont l'épouse ou l'époux, l'enfant, le père ou la mère décède, a droit à un congé dc deuil de trois (3) jours consécutifs.I.c- jours ouvrables durant ces trois jours doivent cire payés à raison de neuf (9) heures par jour au Iaux normal.10.02 Dans le cas du décès d'un frère ou d'une soeur, l'employé a droit, le jour des funérailles >i i Iles ont lieu un jour ouvrable à un jour de congé payé ù raison de neuf (9) heures au taux normal.Article XI ( oiigés payés 11.01 La période de référence s'étend du 1er mai dc l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.Tout employé qui.au 1er mai, a été régulièrement au service de son employeur pendant une période d'une année ou plus, a droit à un congé payé d'une semaine, au moment qui convient à l'employeur.L'indemnité afférente audit congé est égale à du salaire brut de l'employé pendant la période de référence.11.02 Tout employé qui.au 1er mai.a été régulièrement au service de son employeur pendant une période de trois (3) ans ou plus, a droit à un congé payé de deux semaines, au moment qui convient à l'employeur.L'indemnité afférente audit congé est égale à I'du salaire brut de l'employé pendant la période de référence 11.03 Tout employé qui, au 1er mai, a été régulièrement au service dc son employeur pendant une période de quinze (15) ans ou plus a droit ù un congé payé de trois semaines, au moment qui convient à l'employeur.I.indemnité afférente audit congé est égale à B1, du salaire brut de l'employé pendant la période de référence.11.04 L'indemnité de congés doit être versée à l'employé avant son départ en vacances.11.05 Si l'emploi d'un employé prend fin, l'indemnité de congé doit être calculée et payée selon les dispositions de l'ordonnance no 3 de la Commission du salaire minimum du Québec.Article XII Durée du travail 12.01 La semaine normale de travail est de quarante-cinq (45) heures réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi.Cependant, chaque Artjcle IX General holidays with pay 9.01 New Year's Day, (îood Friday, St.Jean Baptiste Day, Canada Day, Labour Day, Thanksgiving Day and Christmas Day shall be general holidays with pay.Holiday pay shall equal nine (9) hours a day at the regular rate, provided the employee has worked on the working day preceding and the one following the holiday, unless on authorized leave.9.02 The holiday shall be paiil regardless of the day on which it occurs.Article X Special leave 10.01 Should his spouse, child, father or mother pass away, an employee shall be entitled to three (3) consecutive days' leave.Working days occurring during these three days shall be paid on the basis of 9 hours a day at the regular rate.10.02 Should his brother or sister pass away, the employee shall be entitled to one day's leave with pay, on the basis of 9 hours at the regular rate, on the funeral day, if it takes place on a working day.Article XI Vacations with pay 11.01 The qualifying period runsfrom May 1st of the previous year to April 30th of the current year.Every employee who, on May 1st, has been steadily in lus employer's service for one year or more is entitled to one week's vacation with pay, at a time convenient to the employer.Vacation pay equals 2% of gross wages earned by the employee during the qualifying period.11.02 Every employee who, on May 1st, has been steadily in his employer's service for three (3) years or more is entitled to two weeks' vacation with pay, al a time convenient to the employer.Vacation pay equals 4% of gross wages earned by the employee during the qualifying period.11.03 Every employee who, on May 1st, lias been steadily in his employer's service for fifteen ( 15) years or more is entit led to three weeks' vacation with pay, at a time convenient to the employer.Vacation pay equals 6% of gross wages earned by the employee during the qualifying period.11.04 Vacation pay shall be given to the employee before he leaves on vacation.11.05 On termination of employment, payment of vacation pay shall be made in accordance with the Minimum Wage Commission's Ordinance No.3.Article XII Hours of work 12.01 The standard work week is forty-five (45) hours, Monday through Friday, However, each year, between the 1st of September and the 3432 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, ?i° 25 année, «lu 1er septembre d'une année au 30 juin dc l'année -suivante, il est loisible à l'employeur d'établir une semaine normale de quarante-cinq (45) heures du lundi midi au samedi midi applicable exclusivement : a) aux employés assurant directement la vente au détail; b) aux employe's assurant la |x>sc et l'installation de miroirs; c) aux employés assurant la pose et l'installation de glace d'automobiles.12.02 Tout travail accompli en dehors des heures normales prévues à l'article 12.01 est considéré comme du travail supplémentaire et doit être rémunéré au taux horaire normal majoré dc 50%.12.03 Si un employé travaille exclusivement dans l'atelier ou l'usine de l'employeur plus de neuf (9) heures dans la même journée, il doit être payé au taux majoré dc 50% pour toute heure ou fraction d'heure cn sus «le neuf (9) heures.Dans tous les autres cas qui comportent un travail à l'extérieur, l'employé a droit au taux majoré dc 50% pour toute heure ou fraction d'heure en sus de dix (10) heures.12.04 Tout travail exécuté le dimanche doit être rémunéré au taux horaire normal majoré de 100%.12.05 Tout travail exécuté un jour férié payé doit être rémunéré au taux majoré de 50%.12.06 Appels d'urgence: Si un employé est rappelé d'urgence après sa journée normale de travail pour effectuer des travaux de réparation à l'extérieur, il doit être payé au taux majoré de 50% à compter de l'heure dc son départ de sou domicile jusqu'à l'heure de son retour.L'indemnité minimale pour un tel travail doit être au moins égale à quatre (4) heures de travail au taux normal.12.07 Le cumul des majorations pour heures supplémentaires est interdit.12.08 L'employé victime d'un accident du travail qui nécessite son absence du travail pour visiter le médecin ou l'Iwpital, a droit à sa journée normale de travail le jour de l'accident.12.09 Tous les employés ont droit à une période de repos de dix (10) minutes, sans perte «le salaire, dans l'avant-midi et à une autre semblable dans l'après-midi sur les lieux du travail.L'employeur peut fixer le moment de ces périodes de repos.Auticle XIII 13.01 Déplacements et ouvrages locaux: Pour les ouvrages locaux exécutés dans la zone desservie par la Commission de Transport de Montréal, l'employeur doit fournir le transport aller et retour et payer tout employé au taux normal ou au taux supplémentaire, selon le cas, jusqu'au retour de ce dernier à l'atelier si le travail est achevé et s'il doit retourner à l'atelier, ou jusqu'à l'heure de suspension du travail sur le chantier si l'employé n'est pas obligé de retourner à l'atelier.Si le chantier est situé au-delà de la zone desservie par la Commission de Transport de Montréal et si l'employé n'a pas à retourner à l'atelier, l'employeur doit fournir alors le transport de cet employé jusqu'aux limites de la zone desservie et compter le temps pour s'y rendre.13.02 Outrages en dehors de la ville: Par ouvrages en dehors dc la ville, on entend ceux pour lesquels l'employeur exige que les employés logent following 30th of June, the employer may schedule tliis 45-hour standard work week from Monday noon to Satur«lay noon inclusively for the following employees only: (a) employees directly required for retail sides; (6) employees required for setting and installing mirrors; (c) employees required for setting and installing automobile glass.12.02 All work performed outside the standard hours of work set forth in subsection 12.01 above is considered as overtime work and shall be renuraeroted at the rate of time and one half.12.03 If an employee works exclusively in the employer's shop or plant more than nine (0) hours in the same day, he shall be paid time and a half for each hour or portion thereof exceeding nine (9) hours.In all other cases involving outside work, time and a half shall be paid for each hour or portion thereof exceeding ten (10) hours.12.04 Any work done on Sunday shall be remunerated at the rate of double time.12.05 Any work performed on a general holiday with pay shall be rcnumcrated at time and a half.12.06 Emergency call: When an emergency call is maile after the regular working ilay for outside repair jobs, the employee shall be paid at time and a half from the time he leaves home until he returns thereto.The minimum payment for such work shall equal not less than four (4) hours' time at the regular rate 12.07 In no case shall there be any pyramiding of overtime.12.08 An employee who is the victim of a work accident requiring him to leave his work lo visit the doctor or the hospital shall be entitled lo a regular day's pay for the accident day.12.09 A 10-minute rest period without loss of pay shall be granted to all employees in the forenoon and another in the afternoon on the work premises.The employer may schedule such rest periods Auticle XIII 13.01 Transportation and local jobs: In the case of local jobs situated within the zone serviced by the Montreal Transportation Commission, the employer shall provide transportation to and from shop to jobs and pay employees at regular or overtime rates, as the case may be, until such time as the job is completed anil the men have returned to the shop or until the work is finish d on the job for that particular day, if the employee is not required to return to the shop.If the job is outside the zone serviced by the Montreal Transportation Commission and if the employee is not requireil to return to the shop, then the employer shall provide transportation to this employee to the limits of the zone serviced as aforesaid and shall allow for the time required to reach such zone.13.02 Out-of-town jobs: Out-of-town jobs an' those at job-sites where the employee is requin I by the employer to stay overnight.The employer QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, A'o.25 3433 sur place.Dans le cas d'un ouvrage cn dehors dc la villi, l'employeur doit fournir le transport aller ,l retour et doit payer jusqu'à concurrence de 85 pour lea repas; il doit payer aussi les autres dé-jk'i -i - ordinaires ou nécessaires et il doit compter le temps do voyage.I.e temps du voyage ne comprend pas cependant le voyage de nuit lorsque l'employeur fournit le prix d'une couchette ni le temps de résidence à rbfll el si l'employeur fournit le prix de In chambré.1303 Allocation dc repas: Lorsqu'un employé iloit travailler pour trois heures ou plus après l'heure où il finit normalement son travail sans en avoir été avisé la veille, il a droit à une somme île 82 pour son souper.S'il est avisé la veille qu'il doit travailler le lendemain et qu'on ne le fait pas alors travailler, il a alors droit à une indemnité forfaitaire de $2.13.04 Voyages à Tiilérieur: Si un employé doit royaler le dimanche pour les affaires de la compagnie, il doit être payé au taux normal Jusqu'à 22 h.Aiitjci.k.XIV Apprentissage 14.01 La durer de l'apprentissage est: u1 pour les « monteurs-mécaniciens » et les \u2022 monteurs compagnons » île quatre (4) années; b) pour les « monteurs dc verte et de panneaux à tympan » de deux (2) années.11.02 Les taux de salaire îles apprentis sont les suivants: m pmr les monteurs-mécaniciens et monteurs-eom|>ugnons pour la première année d'apprentissage, 00% du taux de la classe « A » alors cn vigueur; pair lu deuxième année d'apprentissage.\"0% du taux de la élusse « A » alors cn vigueur; pour la troisième année d'apprentissage, 80% du taux de la classe « A » alors cn vigueur; POUT la quatrième année d'apprentissage, 00% du taux de la classe « A » alors cn vigueur.I pour les mouleurs de verre et de pimicaux à tympan, pour lu première année d'apprentissage, 70',' du taux de la classe « A » alors en vigueur; pour la deuxième année d'apprentissage, 80% du taux de la classe < A » alors en vigueur.14.03 Dès son entrée dans l'industrie assujettie au décret, l'apprenti doit s'inscrire nu comité paritaire afin de rendre possible la vérification des différents stages de son apprentissage et de son expérience.L'employeur ne peut engager un apprenti qui ne s'est [mis conformé à la présente disposition.11.04 Pour être admis, tout apprenti doit avoir 10 ans révolus et avoir subi un test d'aptitudes du comité.Son admission est sujette à la décision des membres du comité.Il y a appel de la décision du comité au ministre du Travail.14.05 Après chaque année d'apprentissage, de même qu'à l'expiration de son apprentissage, I apprenti doit se présenter devant le bureau d'examinateurs du comité itaritairc pour y subir l'examen requis en vue de l'obtention de son certificat de qualification ou dc sa qualification pour I année suivante d'apprentissage.14.06 À la fin de leurs études dans mie école de l'enseignement spécialisé du ministère de l'Éducation relatif à l'industrie du verre, les élèves doivent recevoir un crédit d'apprentissage selon le nombre d'années d'études et les résultats de hurs examens.shall provide transportation to and from the job and pay up to a maximum of So for meals.He shall also pay other ordinary or necessary expenses as well as travelling time.Travelling time sliall not include, travelling overnight when the employer has provided a sleeping berth nor time spent overnight at any hotel room provided by the employer.13.03 Meal alloieanee: When employees are requested to work three hours or more beyond their regular quilling lime without, having been notified the previous day lliul they would have to work, the employer shall pay each employee an amount of $2 for supper.If, after being so advised, he is not required to work, the employee shall then be entitled to a forfeit amount of §2.13.04 Out-of-loirn trips: If an employee has to Iravel on company business on Sunday, the employee shall Ik- paid straight time until 10:00 p.m.of that same day.Aktjci.K XIV Apprenticeship 14.01 The periods of apprenticeship shall be: (a) four (4) years for setter-mechanics and set 1er-journeymen ; (b) two (2) years for setters, glass and spandrel panels.14.02 Apprentices' wage rales sliall be as follows: (a) setter-mechanics and setter-journeymen: for the first year of apprenticeship, 00% of the Class \"A\" rale then in force; for the second year of apprenticeship.70% of the Class \"A\" rate then in force; for the third year of apprenticeship, 80% ol the Class \"A\" rate then in force; for the fourth year of apprenticeship, 90% of the Class \"A\" rate then in force; (b) setters, glass and mandrel panel: for the first year of apprenticeship, 70% of the Class \"A\" rate then in force; for the second year of apprenticeship, 80% of the Class \"A\" rate then in force.14.03 Before beginning his apprenticeship in the industry subject to the decree, the apprentice shall register with Ihe Parity Committee so tlial a record of his stages of apprenticeship and experience may be kept No employer may hire an apprentice who has not complied with this provision.14.04 To be accepted, an apprentice must be age 16 and must have submitted to the aptitude test of the Committee.His acceptance is subject to the final decision of the Committee members.The Committee's decision may lie app-aled to the Minister of Labour.14.05 After each apprenticeship year as well as at the end of his apprenticeship, an apprentice shall submit, before the Hoard of Examiners of the Joint Committee, to the examination required for liis competency certificate or to qualify for his next year of apprenticeship.14.06 On completion of their studies in a specialized school of the Department of Education relating to the Class Industry, pupils shall he granted an apprenticeship credit based on the number of years' study and on their examination results. 3434 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n\" 25 14.07 Le détenteur d'un certificat de qualification de la catégorie « B » ne peut obtenir la catégorie « A » sans s'être, au préalable, inscrit au système d'apprentissage et avoir terminé avec succès les années d'apprentissage déterminées par le comité piritaire.14.08 Le comité piritaire peut exiger que les apprentis assistent aux cours organisés par la Commission d'apprentissage et déterminer le nombre d'heures de cours nécessaires pour être qualifiés.14.09 Le comité peut accorder des crédits d'apprentissage à tout apprenti qui suit, en plus des cours imposés, des cours supplémentaires offerts ou reconnus par le comité.Article XV Durée du décret 15.01 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle de Québec et se termine le 31 octobre 1069.15.02 II se renouvelle automatiquement d'année en année par la suite, à moins que l'une des parties n'avise l'autre du contraire par écrit, et n'en fasse tenir copie au ministre du Travail, entre le 60e et le 30c jour précédant la date d'expiration du présent décret ou de son renouvellement.Advenant pareil avis écrit, le présent décret demeure cn vigueur jusqu'à ce qu'il soit annulé ou remplacé pir arrêté-cn-conseil.Note explicative: Les appellations de certains métiers, emplois, matériaux, outils, engins et parties d'équipement ont été modifiées dans le texte français du présent arrêté pour les rendre conformes à la tcrminalogic française internationale, bien que les appellations en langue anglaise soient demeurées les mêmes.La substitution des nouvelles appellations aux appellations antérieures n'n pis piur effet d'affecter les droits acquis et les intérêts en cours ou d'emp'-eher l'application d'une disposition du présent décret ni, en particulier, d'empêcher l'application des nouveaux taux «le salaires pour lesdits métiers et emplois qui ont une autre appellation «lans le présent dwret, ni d'entamer la validité «les certificats de qualification, des certificats d'apprentis et des certificats d'aptitudes restreintes émis selon les appellations antérieures, ni «le faire obstacle à l'application d'une description dc métier ou d'emploi contenue dans le présent décret.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 25016-o D.Tanguât.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1704 Québec, le 6 juin 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant des modifications au décret relatif aux salariés de garages dans la région de Trois-Rivières et au décret relatif aux salariés de garages «lans la région de Shawinigan.Attexuu que, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143), des parties contractantes aux conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le décret numéro 2142 du 27 octobre 1965 et amendements, 14.07 An employee with a Class \"B\" card shall not be entitled to obtain a Class \"A\" without having first registered in the apprenti, ceship system and without having completed successfully the years of apprenticeship determined by the Joint Committee.14.08 The Joint Committee may require apprentices to attcml courses organized by the apprenticeship commission and may determine the number of hours of attendance to these courses necessary tq be qualified.14.09 The Committee may grant apprenti, ceship credits to any apprentice who, in addition to the compulsory courses, follows additional courses offered or recognized by the Committee.Article XV Term of decree 15.01 The present decree sliall come into force on the date of its publication in the Québtt Official Gazette and shall remain in force until October 31, 1969.15.02 It shall automatically renew itself from year to year thereafter unless a written notice to the contrary be given by either party, with copy thereof to the Minister of Labour, between the 60th and 30th day preceding the expiry (labor the renewal date of the decree Should such notice be given, the prêtent decree shall remain in force until it be cither anniiled or replaced by order in council.Explanatory Note: The names of certain trades, occupations, materials, tools, equipment and equipment romponents have been modified in the French text of this Onlcr in Council to make then consistent with the internationally-accepted French terminology; the English nomenclature remains unchanged.Substitution of the new terms for the old does not affect any vested rights nnd current interest s, nor docs it restrain the application of a particular provision of this decree; in particular, it docs not prevent the application of the new wage rate-set forth for the said trades and occupations that have a «liffcrent name in this decree, nor «loc> it alter the validity of competency certificate-, apprentice certificates and certificates for handicapped workers issued in accordance with the terms previously in use.Moreover, it docs nol hinder the application of any trade or occupational description given in this decree.\" 1).Tanguât, 25016-o Acting Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Numlier 1704 Quéliec.June 6, 1908.Present: The Licutcnant-Covcrnor in Council.Concerning amendments to the decree respiting Garage Employees in the Trois-Rivièn -region and to the decree respecting Garage Employees in the Shawinigan region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1904.c 143), contracting parties to the collective labour agreements respecting Oarage Employees in the Trois-Rivières region (made binding by Decree number 2142 of October 27, 1965, as amended QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, \\o.25 3435 rein I îf aux salariés de garages dans la région dc Trois Rivières, et par le décret numéro 1929 du 29 septembre 1965 et amendements, relatif aux salariés de garages dans la région dc Shawinigan, lui o'it présenté des requêtes à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines modifications auxdits décrets; A mix ou que lesdites requêtes ont été publiées dan la Gazette officielle de Québec, éditions du 10 février 1968 et 2 mars 1968; A rTEX du que l'appréciation des objections, qui ont été formulées contre l'approbation des molifications proposées, a fait ressortir, entre autres, la nécessité qu'un seul décret soit rendu dans ces deux (2) régions limitrophes, liant également tous les salariés et les employeurs dani le champ d'application professionnel défini, cn remplacement des décrets précités; Attendu que les parties contractantes aux conventions collectives déjà rendues obligatoires, soit: I.Association des Marchands d'automobiles de la Mauricie; l.a Fraternité des Détaillants d'essence du Québec, section locales 402 et 408; I,Tnion commerciale Mauricienne Inc., section garagistes et détaillants d'essence; L'Association des grossistes en pièces d'automobiles de la région de Trois-Rivières; D'UNE part, et Les Ouvriers Unis des Textiles d'Amérique, section locale 390, section garage; 1a Fraternité Canadienne des Cheminots, employés des transports et autres ouvriers, section locale 298 11 mu; part pour les employeurs et les salariés des métiers, emplois visés, deviennent parties contractantes au présent décret, adopté conformément aux dispositions de l'article 4 dc la Loi des décrets de convention collective; h.est ordonné, en conséquence, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: Que lesdites requêtes soient acceptées confor-nii ment aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 143) avec, toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites dans la Gazette officielle de Quittée, éditions des 10 février 1968 et 2 mars IP'JS.Première Partie Dispositions générales applicables à tous les salariés assujettis au présent décret (employés de garages, grossistes en pièces, etc.) Article 1 Définitions: Aux fins du présent décret, les mots et termes suivants ont la signification qui leur est ici donnée: 101 Le terme «accessoires de véhicules à moteur» comprend les silencieux, les amortisseurs, les courroies, les accumulateurs, les boyaux, les thermostats, les vis platinées, les bougies, les c->uie-glaces, les phares, les filtres, les garnitures d freins et toutes autres pièces qui peuvent être ajoutées ou enlevées sans nuire au fonctionnement normal des véhicules à moteur.1.02 Le mot « apprenti » désigne tout salarié qui apprend un des métiers régis par le présent décret.and Garage Employees in the Shawinigan region (made binding by Decree number 1929 of September 29, 1905, as amended), hove petitioned the Minister of Labour to submit certain amendments to the said decrees to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision; Whereas the petitions were published in the Québec Official Gazette of February 10.1968 and March 2, 1908; Whereas due consideration of the objections raised against the approval of the proposed amendments brought to fore the necessity of having one decree cover these two (2) adjacent regions, bind all employees anil employers within the professional jurisdiction herein defined and supersede the aforementioned decrees; Whereas the contracting parlies to the collective agreements which bad been mdac binding, to wit : L'Association des Marchands d'automobiles de la Mauricie: La Fraternité des détaillants d'essence du Québec, locals 402 and 408: L'Union commerciale Mauricienne Inc., section garagistes et détaillants d'essence: L'Association des grossistes en pièces d'automobiles dc la région dc Troisdliiières; and The United Textile Workers of America, local 390, garage section; The Canadian Brotherhood of Railway, Transport ami (iencral Workers which represent employers and employee in the trades and occupations concerned become contracting parties to the present decree which was adopted in pursuance of section 4 of the Collective Agreement Decrees Act; It is ordered, then-fore, upon the recommendation of the Honourable Minister of Lubour: That the petitions be accepted pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1904, c.143), with however, the following new provisions replacing the conditions described in the Québec Official Gazette of February 10.1968 and March 2, 1968.Part one General prorisions governing all employees corercd by this decree Section 1 Definitions: For the purposes hereof, 1.01 \"motor vehicle accessories\" means and includes: mufflers, shock absorbers, belts, batteries, hoses, thermostats, poults, plugs, windshield wipers, lights, filters, brake linings and all other parts tliat can lie added to or removed from any motor vehicle without impairing its normal operation; 1.02 \"apprentice\" means any employee who learns one of the trades governed by this decree; 3436 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.22 juin 1968.ICO- année, n' 25 1.03 Le mot < artisan » désigne toute personne qui, sans retenir les services d'un ou de plusieurs employés permanents ou temporaires, exploite individuellement ou en société un établissement régi par le présent décret ou exécute, cn partie ou en entier, une ou plusieurs des opérations faisant l'objet du présent décret pour son propre compte ou bénéfice, que ce soit à forfait, à commission ou autrement.Toute personne qui entreprend, dans une même année, la réparation dc plus d'un véhicule à moteur dans un but de vente ou de spéculation est réputée réparer des véhicules à moteur.Pour avoir le droit d'exploiter un garage ou un atelier de réparations, tout artisan doit être lui-même au moins un compagnon dc classe « B ».Tout employeur doit avoir, cn service dans son établissement, au moins un compagnon dc classe « B ».1.01 Le terme « atelier de mécanique » désigne un établissement où l'on refait, remet en état, répare, règle ou travaille les moteurs, les l>ottes dc vitesse et diverses autres pièces de véhicules à moteur.1.05 Le terme « commis au comptoir * désigne tout salarie qui a la responsabilité de répondre aux clients, de chercher et de déterminer les pièces exactes requises par ceux-ci et de leur en faire la vente.Devient commis « A » celui qui, dans les quatre (4) années précédentes, a acquis trois (3) ans d'expérience à titre de commis « B » dans une même ogence.La présente disposition ne s'applique pas aux grossistes en pièces et accessoires d'automobiles.1.06 Le mot «compagnon» désigne tout salarié qui a terminé son apprentissage et obtenu le certificat dc qualification exigé pour pratiquer l'un des métiers de l'industrie dc la réparation des véhicules à moteur et visés par le présent décret, tels que: charron, carossier, électricien, forgeron, machiniste, mécanicien, dégraisscur de garnitures intérieures, peintre, soudeur, spécialiste du radiateur, spécialiste dc l'alignement des roues, sp:cialistc du différentiel, spécialiste des freins, metteur nu point, spécialiste du chassis, spécialiste du système d'échappement, vitrier, vérificateur, rembourreur de véhicule à moteur, spécialiste dc bottes dc vitesses automa-liqucs.spécialiste dc lu suspension, vulcanisa -teur etc.1.07 Le mot « démonteur \u2022 désigne toute personne qui démonte des véhicules à moteur.LOS Le mot «garage» désigne tout endroit où l'on fait la réparation, la transformation, le démontage ou le remisage des véhicules à moteur.Sont considérés comme garages et par conséquent assujettis au présent décret, tous les établissements où se fait, cn tout ou cn partie, l'installation, la réparation ou la remise cn état des moteurs, des accessoires ou pièces nécessaires A la conduite ou au fonctionnement d'un véhicule à moteur, que ces accessoires ou pièces soient séparés du véhicules à moteur ou non.1.09 Le mot « pompiste » désigne tout salarié qui travaille dans un poste d'essence 1.10 Le terme « poste d'essence » désigne tout endroit fixe ou mobile où se fait exclusivement la vente d'essence ou de lubrifiants pour l'usage «les véhicules a moteur, que ledit endroit soit exploité par un propriétaire ou un locataire comme établissement principal ou comme annexe d'un établissement principal.1.03 \"artisan\" means anyone who, without employing one or more regular or supernumerary employees, operates an establishment governed by this decree, alone or in partnership, or CSI i its out.in whole or in part, one or more operations covered by the decree for himself, be it by con-tract, on a commission basis or otherwise.Anyone who, within a given year, undertakes the repair of more tlian one motor vehicle for sale or speculation purposes is considered as repairing motor vehicles.In order to have the right to operate a garage or repair shop, every artisan must himself be at least a dan \"B\" journeyman.Every employer must have at least a class \"B\" journeyman in his employ; 104.\"machine shop\" means any establishment where motors, transmissions and various motor vehicle part - are reconditioned, repaired, adjusted or worked upon; 1.05 \"counter clerk\" designates any employee who waits on customers, finds, determines ami sells them the exact parts they require.Shall become a class \"A\" clerk, anyone who.in the four (4) previous years, has acquired three (3) years' experience as a class \"B\" clerk in the same establishment.This provision doe-not apply to automobile parts nnd accessories wholesalers; 1.06 \"journeyman\" designates any employee who has completed bis apprenticeship ami has obtained the necessary competency certificate for plying one of the following uutomohih-inilustry trndes governed by this decree: whccl-wright.bodyman.electrician, blacksmith, machinist, mechanic, upholstery cleaner, painter, welder, radiator specialist, wheel alignment sp-cialist.tune-up specialist, brake specialist, differential specialist, frame specialist, exhaust system sp-cialist, glazier, tester, upholsterer, automatic transmission specialist, suspension specialist, vulcanizer and so on; 1.07 \"wrecking mechanic\" means any person who dismantles motor vehicles; 1.08 \"garage\" means any place where motor vehicles are repaired, modified, demolished or stored.The following are also considered as garages and therefore subject to the «lecree: all establishments where motors, accessories or parts neccs-a ry for the driving of a motor vehicle ure repain i or reconditioned entirely or in part, whether such accessories or parts be part of the motor vehicle or not; 1.09 \"pump attendant\" means any employee who works in a gasoline station; 1.10 \"gasoline station\" means any mobile or stationary place where only motor vehicle gasoil nes and lubricants arc sold, whether or not such place is operated by a proprietor or by a lessee u-a main or secondury business concern; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3437 1.11 Le terme « poste ou magasin de pièces et accessoire! d'autos » désigne tout endroit où sr fuit le déballage, l'emmagasinage, la vente et la livraison îles accessoires ou pièces d'équipement de garage ou de pièces d'équipement, neufs ou usagés, nécessaires à la conduite ou au fonctionnement des véhicules ù moteur.Lesétablisse-nicn I s i létachés des garages ou ateliers mécaniques ue - 'id pus exclus.1.12 Les mots < poste de vente ou atelier de pneus désignent tout établissement où les services consistent exclusivement dans la vente de pneus, au gros ou au détail, le rechapage, la vulcanisation, le changement de pneus, l'équilibrage ou l'alignement des roues.1.13 Le terme « préposé aux pièces» désigne tout -alarié affecté au déballage, a l'emmagasinage à la livraison et à l'expédition des pièces ou accessoires de véhicules à moteur, et qui, à celle lin, aide les commis au comptoir.1.14 a) Le terme * préposé nu service » désigne tout salarié qui vend dc l'essence ou des lubrifiants, graisse, lave ou conduit les véhicules ù noteiir, fait le nettoyage ou le chauffage dc 1 cta-bli\u2014ement, change ou réparc les pneus, ou les accessoires de véhicules ù moteur.'\u2022i be montage îles postes dc radio, des appareils de climatisation d'air et des interrupteurs île ¦ lignotants doit être fait par un compagnon.1.15 Le terme « préposé à la préparation des autos \u2022 désigne un salarié qui, sans accomplir le travail d'un compagnon ou d'un apprenti, a comme tâche principale de préparer une automobile neuve ou d'occasion, pirticulièrcnient en vue de la revente, cn nettoyant le moteur, les tapis, les housses, etc., et en s'occupant des accessoires tels que rétroviseurs, enjoliveurs «le roues, etc.1.1(5 Le terme « receveur-expéditeur dans un entrepôt » désigne tout salarié affecté à la réception, au déballage, à l'emmagasinage, à la livraison, à l'expédition «le matériel dans un entrepôt distinct ou détaché d'un garage ou atelier de mécanique.1.17 Le terme « receveur-expéditeur aux pièces et accessoires » désigne tout salarié affecté A la réception, au déballage, à l'emmagasinage, k \"expédition «le pièces ou accessoires de véhiculcsà moteur.1.18 Le mot « salarié1 désigne tout apprenti, manoeuvre, compagnon ou ouvrier qui exécute individuellement, en équipe ou en société, du travail régi par le présent décret.I 19 Le terme « station-service » désigne tout pi-te «lans lequel: a) on vend de l'essence et des lubrifiants; l>i on vend, monte et réparc les pneus; i I on lave, nettoie, polit, lubrifie et remise les véhicules à moteur; il) on donne un service de dépannage; \u2022 i on vend et monte les pièces d'équipement énuraérées à l'article 1.01.Toutefois, si une station-service possède une si et ion «le mécanique ou de réparation de véhicule à moteur, ladite section est considérée aux lins «lu présent décret, comme un garage et assujettie aux conditions de travail des garages ou ateliers de mécanique.1.20 Le terme «terrain de démontage» désigne tout endroit où les véhicules à moteur ou certaines parties de leurs pièces sont démontées «lans un but de vente, d'emmagasinage, de réparation ou pour la ferraille.1.11 \"automobile parts or accessories store\" means any place where new or used accessories or parts, garage equipment or equipment parts required for the operation of motor vehicles are unpacked, stored, sold or delivered.Establishments separate from garages or machine shops are included; 1.12 \"tire store or shop\" means any establishment whose services consist solely in: selling tires on a retail or wholesale basis; retreading, vulcanizing and changing tires; balancing or aligning wheels; 1.13 \"spare parts man\" means any employee who unpacks, stores, delivers and ships motor vehicle parts or accessories, thereby helping counter clerks 1.14 (a) \"serviceman\" means any employee who sells gasoline or lubricants; lubricates, washes or drives motor vehicles; cleans the establishment and looks after its heating; changes or repris tires or motor vehicle accessories.(b) Radio, air conditioner and flasher switch installations must be \u2014 Class \"C\".1.82 2 00 Apprenti soudeur, bobineur, préposé à la remise en état \u2014 Apprentice welder, winder and reconditioner: 1ère année \u2014 1st year.1.15 1.25 2c minée \u2014 2nd year.1.40 1.50 3c année \u2014 3rd yenr.1 55 1.65 ( liasseur, concierge, gardien et autres fonctions non autrement spécifiées \u2014 Messenger, janitor, watchman and other occupations not otherwise specified.1.30 1.40 Zone II ( Compagnon mécanicien, carrossier, peintre \u2014 Journeyman mechanic, body-man, painter: Classe « A \u2022 Class \"A\".2.05 2.25 Classe « B » \u2014 Class \"B\".1.85 2.05 Classe « C » - Class \"C\".1.67 1.85 Ponceur Sander.1.25 1.35 Aide-pmccur \u2014 Sander's helper.1.10 1.20 Apprenti mécanicien, carossier, peintre \u2014 Apprentice mechanic, bodyman, painter: 1ère année - 1st year.1.10 1 20 2e année - 2nd year.1.25 1.35 3c année \u2014 3rd year.1 - 45 1.55 Préposé aux pièces - Parts man: 1ère année - - 1st year.1.05 1.15 2e année \u2014 2ml year.1.25 1.35 3c année - 3rd year.1.35 1.45 Classe « B » \u2014 Class \"B\".1.50 1.60 Classe « A » \u2014 Class \"A\".1.60 1.70 Préposé au service \u2014 Service man : 1ère année \u2022 - 1st year.1.00 1.10 2e année \u2014 2ml year.1.26 1 35 3e année - 3rd year.1.40 1.50 Soudeur de radiateur \u2014 Radiator welder: Classe « A » \u2014 Class \"A\".2.05 2.25 Classe « B » \u2014 Class \"B\".1 85 2.05 llobincur et préposé à la remise en état ¦ Winder and reconditioncr: Classe « A » \u2014 Class \"A\".2.05 2.25 Classe « B > \u2014 Class \"B\".1 85 2.05 Classe « C » \u2014 Class \"C\".167 1.85 Apprenti soudeur, bobineur et préposé à la remise en état1\u2014 Apprentice welder, winder and reconditioner: 1ère année \u2014 1st year.1 00 1.10 2e année \u2014 2nd year.1-25 1.35 3c année \u2014 3rd year.1 40 1.50 Chasseur, concierge, gardien et autres fonctions non autrement spécifiées \u2014 Messenger, janitor, watchmen and other occupations not otherwise specified.115 125» U greffier suppléant du Conseil exécutif.!>\u2022 Tanguât, 25016-o D.Tanouay.25016-o Acting Clerk of the Executive Council. GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 19GS, 100' année, n° 25 Arrêté cn conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1703 Québec, le 6 juin 19(58.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant «les modifications au décret relatif à l'industrie de la construction «lans la région de Sorel.attendu que, conformément aux dispositions dc la Loi «les décrets de convention collective (Statuts refondus du Québec 1964.chapitre 143), les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le décret numéro 2210 du 18 novembre 1964 et amendements, relatif à l'industrie de la construction dans la région de Sorel, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil certaines mollifications audit décret; ATTENDU QUE ladite requête a été publiée «lans la Gazette officielle tin Quflicc.edit ion «lu 13 janvier 1968; ATTENDU Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation «les modifications proposées; Ii.est «mdonné., en conséquence, sur la proposition dc l'honorable ministre du Travail: Que ledit décret, numéro 2210.soit modifié comme suit: 1° L'article I (Définitions) du décret numéro 2210.relatif à l'industrie dc la construction dans la région de Sorel.fait partie intégrante du présent décret comme s'il y était reproduit en entier.(Il s'agit dc l'article I en vigueur avant, la passation de l'arrêté en conseil humera 3032 du 15 novembre 1967).2° Le paragraphe 2.10 est remplacé par le suivant: « 2.16 Le terme «construction industrielle* pour les fins du présent décret, comprend tous les travaux de construction de plus de $125.000, salaires et matériaux compris.Pour les fins du présent paragraphe, on lient compte rie la valeur totale «les travaux compris dans le champ d'application du présent dé'crcl et exécutés simultanément pour le compte d'un établissement donné, quel que soit le nombre de contrats.» 3° Les métiers suivants sont ajoutés après l'appellation «Poseur dé lattis métallique» apparaissant au paragraphe 11.01, dans l'échelle intitulée «Classe A ¦ Const met ion industrielle - ¦ Métiers: 1er octobre 1068 « Poseur de lattis «le bois et matériau composite.$4.20 $4.20 Poseur de linoleum et tapis 4.20 4.20» 4° L'appelalion suivante est ajoutée après l'appellation « Conducteur «le camion remorque » apparaissant au paragraphe 11.01, Classe « A » \u2014 Construction industrielle \u2014 Opérations: 1er octobre 1068 < < '«inducteur de camion (grue mobile).$4.42 $4.42» 5° Les mots suivants sont ajoutés à la suite de l'nppelation «(initier» apparaissant A l'article 11.01.Classe «A»\u2014Construction industrielle - Opérations: Order in Couneil Executive Couneil Chamber Number 1703 Québec, June 6, 1908.Present: The Lieutenant-Governor in Council, Concerning amendments to the decree respecting the Construction Industry in the Sorcl region.Whereas, pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (IiSQ 1984, c.143), the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Construction Industry in the Sorel region (made binding by Decree number 2210 of November 18.1901, as amended), have petitioned the Minister of Labour to submit certain amendments to the said decree to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision; Whereas the petition was published in the Québec Official Gazelle of January 13, 196S; Wiikhkas no objection was brought forth against the approval of the proposed amendments; It isoudkiikd, therefore, ii|x>n the recommendation of the Honourable Minister of Labour: That sai«l Decree number 2210 be amended as follows: 1.Section I (Definitions) of Decree number 2210 (Construction Industry in the Sorel region) forms part of the present decree just as though it were quoted herein in its entirety.(The Section I in question was in force before the adoption of Order in Council number 3032.dated November 15.1907).2.Subsection 2.16 is superseded by Ihe following: \"2.16 For the pur|X)ses of this decree, \"industrial construction\" includes all construction work over $125.0(H) (laliour and materials included).For the purposes of the present subsection, the total value of projects within this decree's jurisdiction which arc carried out simultaneously on behalf of a given establishment, rcgardle-s of the number of contracts, is taken into account.\" 3.The following trades are added after that of \"metal lather\" listed under \"Class \"A\" Industrial construction \u2014 Trades:\" in subsection 11.01: Octobtr ¦ 1968 \"Lather, wood and composition.$ 4.20 $ 4.211 Linoleum and carpet layer 4.20 4.20\" 4.The following occupation is added after that of \"Driver, tractor-trailer\" listed under \"Class \"A\" \u2014 Industrial construction \u2014 Operations:\" in subsection 11.01 : October I.1968 \"Driver, truck (mobile crane).$4.42 $4.42\" 5.The following item is added after that of \"Operator, mobile cranes\" listed under \"Class \"A\" \u2014 Industrial construction \u2014 Operations:\" in subsection 11.01 : QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, So.25 3451 1er octobre 1968 \u2022 ( i rue automotrice à fonctionnement hydraulique, d'une capacité d'au plus 20 tonnes.S 3.75 $3.75» 0° Ix-s métiers suivuuts sont ajoutés après Pippelation « Poseur dc lattis métallique » apparaissant au paragraphe 11.01, dans l'échelle intitulée «Classe «B»\u2014Construction industrielle- -Métiers: 1er octobre 1968 Poseur de lattis de bois et matériau composite.» S 3.36 $3.05 Poseur de linoleum et tapis 3 20 3.50» 7° L'appellation suivante est ajoutée après l.i puliation « Conducteur de camion remorque » apparaissant au paragraphe 11.01, Classe « B » \u2014 i ipérat ions: 1er octobre 1968 (Conducteur de camion igruc mobile).8 3.70 $ 3.08» 8° L'appellation* Poseur de linoleum.$2.95.$3.20.$3.50 » apparaissant au paragraphe 11.01 à la lin de l'échelle intitulée «Classe «B» \u2014 Autres constructions » est bille.9° Les métiers suivants, avec indication du nombre d'années d'apprentissage, sont ajoutés à l'alinéa « / du paragraphe 15.24: \u2022 Aplanisseur de parquets .2 ans .li'intoycnr.2 ans Mécanicien de machinerie.4 ans Plâtrier.4 ans l'uvrier |iaysagiste.2 ans < 'inducteur de machinerie lourde.2 ans Poseur dc linoleum et tapis.2 ans » Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 260164 I>.Tanouay.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1399 Québec, 15 mai 1908.Présent: Ix; Lieutenant-gouverneur en conseil.I oncehnant les Règlements relatifs aux normes du travail dans l'exécution îles contrats et sous-contrats de construction du Gouvernement du Québec.Attendu que l'Assemblée Législative de Quéliec.a adopté, le 14 avril 1908, la résolution suivante: s Que tous les contrats du Gouvernement devraient contenir les conditions nécessaires pour prévenir les abus qui peuvent se présenter dans les -ous-eoutrats et qu'on devrait faire tous les efforts possibles pour payer aux ouvriers les gages courants dans la localité où l'ouvrage se fait, tels (pie payés aux ouvriers compétents, et cette Chambra concourt cordialement dans cette politique et croit que c'est le devoir du Gouvernement de donner effet immédiatement à cette résolution ».Attendu que l'arrêté ministériel no 800 du -I avril 1929.amendé par les arrêtés nos 2393 du 0 octobre 1932 et 706 du 3 mars 1944, donnant suite à In résolution précitée, a besoin d'une revision complète, qui tienne compte dc l'adoption de la loi des décrets de convention collective et de la loi du salaire minimum.October 1, 1068 \"Crane, sett-propelled, hydraulic, up to 20-ton capacity.$ 3.75 $ 3.75\" 6.The following trades are added after tliat of \"Metal lather\" listed under \"Class \"B\" \u2014 Industrial construction \u2014 Trades:\" in subsection 11.01: October 1, 1068 \"Lather, wood and composition.$ 3.35 $ 3.65 Linoleum and carpet layer 3.20 3.50\" 7.The following item is added after that of \"Driver, tractor-trailer\" listed under \"Class \"B\" \u2014 Operations:\" in subsection 11.01: October 1, 1068 \"Driver, truck (mobile crane).$3.70 $3.98\" 8.In subsection 11.01.the item \"Linoleum layer.$2.95.$3.20.$3.50\" listed under \"Class \"B\" \u2014 Other construction\" is deleted.9.The following trades, together with their respective terms of apprenticeship, are added to paragraph \"/\" of subsection 15.24: \"Floor sander.2 years Joint-pointer.,.2 years Equipment mechanic.4 years Plasterer.4 years Landscape man.2 years Heavy equipment operator.2 years Linoleum and carpet layer.2 years\" I).Tanguay, 25016 Acting Clerk of the Executive t 'ounoU.Order in Council Executive Couneil Chamber Number 1399 Québec, May 15, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning regulations on labour standards to be observed when carrying out Québec Government construction contracts and subcontracts.Whereas, on April 14, 1908, the Québec Legislative Assembly adopted the following resolution: \"That all Government contracts should contain necessary conditions for preventing abuses that might occur in subcontracts and that every possible effort should be made to pay workmen the wages current in the locality where the work is done, as paid to competent workmen, and this House heartily concurs in such policy and considers it the Government's duty to give immediate effect to this resolution\".Whereas Order in Council number 800, dated April 24, 1929 (amended by Orders in Council numbers 2393, dated October 6, 1932, and 706, dated March 3, 1944), which followed the resolution quoted above, stands in need of a thorough revision that takes into account the adoption of the Collective Agreement Decrees Act and the Minimum Wage Act; 3452 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année.n° 25 Attendu qu'H y b lieu de donner suite à Indite résolution d'adopter de nouveaux réglementa prévoyant un mécanisme administratif rajeuni, pour la determination des normes du travail et pour leur mise en vigueur; Il est ordonne, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail: Qi i: la réglementation ci-jointe relative aux normes du travail dans l'exécution de- contrats et bous-COntrats de construction du Gouvernement du Québec soit approuvée.Le greffier ilu ( 'onxeil exécutif.Jacques Prbmont, Hkcij-.mkxts relatifs ai \\ normes m travail dans l'exécution DES contrats kt sois-contrats de consthi ition du GOUVERNEMENT du QuBHEC.Définitions 1.Duns les présents règlements el leur application, À moins que le contexte ne s'y appose, les ternies suivants ont le sens qui leur est ci-après donné: a) «Commission : La Commission du salaire minimum de la Province dc Quebec: b) « Const met ion comprend: réparation et démolition; r) « Décret : décret ridai if aux méliers de la construction pris en vertu de la Loi de- décrets de convention collective; d) «Ministre»: ministre du Travail de la Province de Quclicc; e) < Salaire signifie: la rémunérai ion en monnaie courante et les compensations ou avantages avant une valeur pécuniaire apparaissant au tableau; /) « Tableau : Tableau des nonnes du travail préparé en vertu de l'article 3 cl comprenant les taux de salaires, le mode de rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, l.*s congés payés, les fêtes chômées pour les salariés affectés aux travaux de construction du Gouvernement provincial.Champ d'application 2.LeS présents règlements s'appliquent à tout entrepreneur ou sous-cut repreneur exécutant |mur le compte d'un ou de plusieurs ministères du Gouvernement, ou pour le compte de toute Commission ou Corporation qui relève directement , « caribou » : sous réserve de l'article 7 du présent règlement, ces mots visent le mâle, la femelle et le petit; 2.U est prohibé de chasser l'orignal, le chevreuil ou le caribou, sauf pendant les périodes fixées en vertu du présent règlement; 3.Concernant l'orignal: la chasse de l'orignal est prohibée dans les zones Al, A2, A3, E, Fl, LetP: o) Elle est permise dans les zones ci-après énumérées pendant les périodes iniliquées: i) dans les zones B, C et F2: du 5 octobre au 13 octobre; ii) dans les zones D, G, M et N: du 28 septembre au 13 octobre; iii) dans les zones H, I, J, K et O: du 21 septembre au 13 octobre; 4.Concernant le chevreuil: la chasse du chevreuil est prohibée dans les zones E, Fl, K, M, N, O et P: a) Elles est permise dans les zones ci-après énumérées pendant les périodes indiquées: i) dans les zones Al, A2, A3, B, C et D: du 19 octobre au 11 novembre; ii) dans les zones F2, G, H, I et J: du 1er novembre au 11 novembre.Cependant, sur le territoire du club Seigneurial, situé dans le comté de Papineau compris dans la zone F2, la chasse est permise du 25 octobre au 18 novembre; iii) dans la zone L: du 1er juillet au 31 janvier; 5.Chasse du chevreuil au moyen de l'arc: il est permis de chasser le chevreuil au moyen de l'arc seulement pendant les périodes suivantes dans les endroits ci-après déterminés: 16.No one may cut trees for camping purposes of for camp fires, without the permission of the authorities of the reserve.That publication be made in the Quebec Official (iazctte.Certified copy.D.Tangiwy, 25019 Acting Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 1681 Quebec, June 5, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the moose, deer and caribou hunting season.Whereas pursuant to paragraph 4 of seel ion 65 of the Game Act (Revised Statutes, 1964, chapter 202), the Lieutenant-Governor in Council may, by regujation, amend the periods during which the hunting of animals provided for by sections 4 and 6 of the said act is prohibited; Whereas it is expedient to determine the moose, deer nnd caribou hunting season.Therefore, it is ordered, ujion the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That pursuant to paragraph 4 of section 65 of the Game Act, the following regulation- be adopted, subject to the particular regulations applying to the fish and game parks, reserves or to the sanctuaries: 1.Definitions: (a) \"Zone\": signifies a binding zone established pursuant to Order in Council number 823 of May 4, 1966, such as amended; (/)) \"Moose\", \"deer\", \"caribou\", subject to section 7 of the present regulation, these words refer to the male, the female and the young; 2.The hunting of moose, deer or caribou is prohibited, save during the periods fixed pursuant to the present regulation; 3.Concerning the moose: the hunting of moose is prohibited in zones Al, A2, A3, K.Fl, L and P: (a) It is allowed in the zones hereafter enumerated during the periods indicated: (i) in zones B, C and F2: from October 5th to October 13th; (ii) in zones D, G, M and N: from September 28th to October 13th; (iii) in zones H, I, J, K and 0: from September 21st to October 13th; 4.Concerning the deer: the hunting of décris prohibited in zones E, Fl, K, M, N, 0 and P: (a) It is allowed in the zones hereafter enumerated during the periods indicated: (i) in zones Al, A2, A3, B, C and 1): from October 19th to November 11th; (ii) in zones F2, G, H, I and J : from November 1st to November 11th.However, on the territory of the Seigniorial Club, situated in the county of Papineau, included in zone F2, hunting is allowed from October 25th to November 18th; (iii) in zone L: from July 1st to January 31st; 5.The hunting of deer with a bow: the hunting of deer is permissible with a bow only during the following periods, in the places hereafter determined: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3405 a) dans la réserve de Rimouski, située dans le comté de Rimouski, du 28 septembre au 18 octobre; cette période spéciale de chasse ne supplique pas sur les territoires des clubs de chasse et de pêche ou sur ceux des pourvoyeurs eu chasse et pêche (outfitters) compris cn totalité ou en partie dans ladite réserve; 6) dans la demi sud-ouest du canton Chabot, situé dans le comté de Kamouraska, du 5 octobre au 18 octobre; c) dans le comté de Maskinongé et cette partie du comté de Papincau située à l'Est de la route 57, du 19 octobre au 31 octobre; C.Concernant le caribou: il est défendu de chasser le caribou dans toute la province, sauf dans la zone O où on peut le chasser du 30 août au 30 septembre; 7.Il est défendu de chasser le chevreuil sans panache dans la zone A3.Que les arrêtés cn conseil numéros 438 du 1er mars 1967, concernant les périodes dc chasse à l'orignal, du chevreuil et du caribou et 2405 du 12 septembre 1967, concernant la chasse sur le domaine du club Seigneurial soient abrogés.Que publication soit faite dans la Gazette njlicielle de Québec.Copie conforme.Ia! greffier suppléant du Conseil exécutif, 25019-o D.Tanouay.(a) on the Rimouski Reserve, situated in the county of Rimouski, from September 28th to October 18th, this special hunting period docs not apply on the territories of Fish and Game Clubs or on those of Fish and Game outfitters included in whole or in part on the said reserve; (6) on the south-west half of the township of Chabot, situated in the county of Kamouraska, from October 5th to October 18th; (c) in the county of Maskinongé and this part of the county of Papincau situated on the east of Route 57, from October 19th to October 31st; 6.Concerning the caribou: the hunting of the caribou is prohibited in all the Province, save in zone 0 where one may hunt it from August 30th to September 30th; 7.The hunting of deer without antlers is prohibited in zone A3.That Order in Council numbers 438 of March 1, 1967, concerning the moose, deer and caribou hunting periods and 2405 of September 12, 1967, concerning hunting on the domain of the Seigneurial Club, be abrogated.That publication be made in the Québec Official Gazette True copy.D.Tanouay, 25019 Acting Clerk of the Executive Council.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1673 Québec, le 5 juin 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur cn conseil.Concernant la division de la province pour les fins dc la chasse.Attendu qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 65 de la Loi de la chasse (Statuts refondus 1964, chapitre 202), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir pour les fins dc la chasse des divisions territoriales.Il est ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme, dc la chasse cl de la pêche: Que 1 arrêté-en-conseil numéro 823 du 4 mai 1966 concernant la division de la province, pour les fins dc la chasse, en dix-huit (18) zones, soit modifié comme suit: a) En retranchant dans la deuxième ligne du titre, les mots < en 18 zones » ; b) En remplaçant dans la deuxième ligne du troisième alinéa, le nombre « 18 » par le nombre « 19»; c) En remplaçant les paragraphes 1°, 2° et 3', par les suivants: 1° Zone Al: cette partie de la province située au sud du fleuve St-Laurent et bornée au sud et BU sud-est par la frontière internationale partant du lleuve St-Laurent jusqu'à la rivière Richelieu, la rive gauche de la rivière Richelieu, dc la frontière internationale à l'autoroute des Cantons de l'Est, l'autoroute des Cantons dc l'Est, de la rivière Richelieu à la route 13 près de Granby, la route 13 jusqu'à l'autoroute 20 près de Drum-mondvillé, l'autoroute 20 jusqu'au pont de Québec; 2° Zone A2: cette partie de la province bornée à l'ouest et au nord-ouest, par la route 13 de l'autoroute des Cantons de l'Est jusqu'à l'autoroute 20 près de Dnunmondville, l'autoroute 20 Order in Couneil Executive Couneil Chamber Number 1673 Québec, June 5, 1968.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the division of the Province for hunting purposes.Whereas pursuant to paragraph 3 of section 65 of the Game Act (Revised Statutes 1964, chapter 202), the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, establish territorial divisions for hunting purposes.It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That Order in Council number 823, dated May 4, 1966, concerning the division of the Province, for hunting purposes, into eighteen (18) zones, be amended as follows: (a) By deleting, in the second line of the title the words \"into 18 zones\"; (6) By replacing, in the second line of the third paragraph, the number \"18\" by the number \"19\"; (c) By replacing paragraphs 1, 2 and 3 by the following: 1.Zone Al : that part of the Province situated south of the St.Lawrence River, and bounded on the south and southeast by the international frontier starting at the St.Lawrence River and going to the Richelieu River, the left bank of the Richelieu River, from the international frontier to the Eastern Townships Autoroute, the Eastern Townships Autoroute from the Richelieu River to Route 13 near Granby, Route 13 to Autoroute 20 near Drummondville, Autoroute 20 to the Québec Bridge; 2.Zone A2: that part of the Province bounded on the west and northwest by Route 13 of the Eastern Townships Autoroute to Autoroute 20 near Drummondville, Autoroute 20 to its junc- 3466 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 jusqu'à sa jonction avec la route 1 près du pont de Québec; au nord-est et au sud-est, par la route 1 jusqu'à sa jonction avec l'autoroute des Cantons de l'Est, au Sud, par l'autoroute des Cantons de l'Est jusqu'à la route 13 au sud de Granby; 3° Zone A3: cette partie de la province bornée au nord, par l'autoroute des Cantons de l'Est, dc la rivière Richelieu jusqu'à la rivière aux Cerises; à l'est, par la rive droite de la rivière aux Cerises et la rive ouest du lac Memphrémagog; au sud, par la frontière internationale, de lac Memphrémagog à la rivière Richelieu; à l'ouest, par la rive gauche de la rivière Richelieu; d) En remplaçant le paragraphe 8° par les suivants: 8° a) Zone Fl: cette partie de la province dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite sud du parc du Mont-Tremblant avec la ligne séparant les comtés de Labelle et dc Terrel>onne, et passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: vers le nord-est, la limite sud-est dudit parc et la route reliant St-Michcl des Saints au canton Forbes; vers le sud-est, la route 43 jusqu'à St-Gabriel dc Brandon; vers le nord-est, la route reliant St-Gabriel dc Brandon, St-Didace, St-Édouard, St-Paulin, Shawinigan, Grand'Mère et St-Titc; vers le sud-est, la route 19A et son prolongement au sud jusqu'au fleuve St-Laurent; vers le sud-ouest, le fleuve St-Laurent; vers le sud-ouest, le prolongement au sud de la route 41 et la route elle-même jusqu'à la limite ouest du comté de Deux-Montagnes; vers le nord et le nord-ouest, les limites est et nord du comté d'Argenteuil; vers le nord, la ligne entre le comté de Terrelionnc d'une part et les comtés de Papineau et Labelle d'autre part, jusqu'au point de départ; 6) Zone F2: cette partie dc la province dont le périmètre peut être décrit comme suit: Partant de l'intersection de la route 11 et de la frontière interprovinciale à Hull, et passant successivement par les lignes et démarcations suivantes: vers le nord, puis l'est, la route 11; vers le nord-est, la rivière Rouge; vers le sud-est puis le sud-ouest, la limite sud-ouest du parc du Mont-Tremblant; vers le sud-ouest.- la limite entre les comtés de Terrebonne et d'Argentuil d'une part, et libelle et Papineau d'autre part, jusqu'à la rivière Outaouais; vers l'ouest, la rivière Oui aimai- jusqu'au point de départ; Que publication soit faite dans la Gazelle officielle de Québec.Copie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 25019-o I).Tanouay.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1676 Québec, le 5 juin 1968.Présent: Le Lieutenant-gouverneur cn conseil.Concernant la citasse de la perdrix.ATTENDU qu'en vertu dc l'article 8 dc la Loi dc la chasse (Statuts refondus 1964, chapitre 202), le lieutenant-gouverneur en conseil |>eut, par règlement, modifier les périodes dc cliassc des différentes espèces dc perdrix.turc with Route 1 near the Québec Bridge, on the northeast and southeast by Route 1 to its juncture with the Eastern Townships Autoroute, on the south by the Eastern Townships Autoroute to Route 13 south of Granby; 3.Zone A3: that part of the Province hounded on the north by the Eastern Townships Auto-route, from the Richelieu River to Rivière aux Cerises, on the east by the right bank of Rivière aux Cerises and the west bank of Lake Mcmphrc-magog, on the south by the international frontier from Lake Memphrémagog to the Richelieu River, on the west by he left bank of the Richelieu River; (arcs, les réserves et les sanctuaires visés par des règlements à cet effet; Que l'arrêté en conseil numéro 482, en date du 1er mars 1967 soit abrogé; Que publication soit faite dans la Gazette officielle de Québec.( 'opie conforme.Le greffier suppléant du Conseil exécutif, 2.-)019-o D.Tanouay.Therefore, it is ordered, upon the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game: That the hunting of the ruffed grouse and the sharp-tailed grouse, from the last Monday of November of one year to the second Friday of the following Septeml>cr, these two days included, be prolubited; That the limiting of the gray partridge, from the second Tuesday of November of one year to the second Friday of the following September, these two days included, be prohibited; That the hunting of the spruce grouse be prohibited : (a) in zone 0, from December 1st of one year to the last Friday of the following August, these two days included; (b) in the remainder of the Province, from the last Monday of November of one year to the second Friday of the following September, these two days included; That the killing or capturing in one day of more than five of these various birds be prohibited ; That the possession of a greater number of the various birds than the legal capture of three daj's, being fifteen, be prolubited; That the possession of these birds be forbidden from January 7th to the date of the opening of the hunting season established by the present regulation; That the limiting of birds in parks, reserves and sanctuaries provided for by regulations to this effect be prohibited; That Order in Council number 482 dated March 1.1967, be abrogated; That publication be made in the Quebec Official Gazette.True copy.D.Tanouay, 25019 Acting Clerk of the Executive Council.Ministère du Travail Department of Labour Avis de prélèvement L'honorable Maurice Bcllemare, ministre du Travail, donne avis par les présentes que le ( 'omité paritaire du Commerce de détail d'Asbes-tos, établi en exécution du décret numéro 1640 du 5 octobre 1960, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1717 du 6 juin 1968, le tout d'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus de Québec 1964, chapitre 143), à prélever des cotisations des employeurs professionnels, des artisans et des salariés assujettis audit décret, suivant les conditions ci-après décrites: 1.Cotisation La période de cotisation s'étend du 21 juin 1068 au 21 juin 1969; cette cotisation s'exerce comme ci-dessous mentionné: a) Les employeurs professionnels régis par ledit décret numéro 1640 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à \\4 de 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret, (salaires fixes, ]>ourcentages, allocations, commissions ou bonis payés).Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (RSQ 1964, c.143).the Honourable Maurice Bellcmare, Minister of Labour, hereby gives notice that the Joint Committee of the Retail Trade of Asbestos (established in pursuance of Decree number 1640 of October 5, 1960) has been authorized to levy dues on the professional employers, artisans and employees subject to the said decree, according to the conditions mentioned below.A by-law, approved by Order in Council number 1717, dated June 6, 1968, authorizes such levy.1.Dues The contribution period extends from June 21, 1968 to June 21, 1969.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said Decree number 1640 and amendments shall pay the Parity Committee an amount equivalent to Yl of 1% of their payroll for employees subject to the said decree (fixed salaries, percentages, allowances, commissions or bonuses paid). 8468 GAZETTE OFFICIELLE DE QlEllEC, 22 juin 19GS, 100' année, n\" 20 b) Les artisans régis par ledit décret numéro 1640 et amendements, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à Yz de 1% du salaire établi dans le décret pour le compagnon le moins rémunéré, soit une cotisation dc 80.15 par semaine.c) Les salariés régis par ledit décret numéro 1640 et amendements, doivent verser nu Comité paritaire une somme équivalente à \\ î de 1% de leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis payés).2.Mode de pourcentage En vue dc faciliter la perception dc ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels des formules de rapport sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenirau ( omité |iaritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration dc la période p>ur laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné dc la cotisation dc l'employeur professionnel et de celles de ses salariés.Le Comité a le pouvoir d'exiger l'asser-mentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisan de payer ses cotisations ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné DOUT remplir ses obligations envers le Comité paritaire.3.Rapport financier D'accord avec les dispositions de la Loi des décreLs de convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de tes opérations financières au ministre du Travail, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé, un état des recettes et des déboursés prévus du Comité paritaire du Commerce de Détail d'Asbcstos, ]x>ur la période conquise entre le 21 juin 1068 et le 21 juin 1909.Comité paritaire nu Commerce de DÉTAIL n'Asbestos Etat des recettes et des débourses probables pour la période comprise entre le 21 juin 1968 et le 21 juin 1969.Recettes: Cotisations patronales.$1,870.00 Cotisations ouvrières.1,870.00 Cotisât ions artisanales.320.00 Intérêts de banque.85.00 Assurance-vie-santé.103.44 Hentcs du Québec.25.74 (b) Artisans governed by said Decree number 1640 and amendments shall turn over lo the Parity Committee an amount equivalent to J .\\ of lr'c of the salary set forth in the decree for the lowest-paid journeyman, i.e., SO.15 a week ilues.(c) Employees governed by said Decree mini-Iter 1640 anil amendments shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to } ¦> of lÇf, of their wages (fixed salaries, percentages, commission, allowances or bonuses).2.Collection of Dues To facilitate the collection of such due-the Parity Committee supplies professional employers with report forms on which nil tbe information requested by the said Parity Com.mittee must Ik- given.Every month, the professional employer shall complete, sign and forward his report to the Parity Committee, At the end of each week and on the Committee's behalf, the professional employer dull collect this levy by means of a check-off.The professional employer shall forward bis monthly report to the Parity Committee on or before the 15lh of the month following the expiry date of the period for which it is required.The professional employer's dues together with those of Ins employees shall accompany the -aid repirt.The Committee has the authority to request an attestation of the said repirt whenever it shall deem it advisable.The levy impised by this by-law is payable monthly by the professional employer, the artisan anil the employee, without formal notice beforehand.Should a professional employer or an artisan refuse to pay bis dues or supply necessary information, he will Ih- given five (5) days' notice so that he may fulfil his obligations towards the Parity Committee.3.Financial Report In compliance with the provisions of the Collective Agreement Decrees Act.the Purity Committee shall submit a quarterly financial repirt lo the Minister of Laliour on the Following set dates: March 31st.lune 30th, September 301 It and December 31st of each year.An estimate of receipts and disbursements of the Joint Committee of the Retail Trade of Asbestos for the June 21.1908 to June 21, 1%'' |ieriod is given below.The Joint Committee Of the Retail Tuaim; of Asbestos Estimate of receipts and disbursements for the June 21, 1968 to June 21.1909 period.Receipts: Employers' dues.$1.870 00 Employces'dues.1.870.00 Artisans'dues.320 00 bank interest.86.00 Health, life insurance.103 41 Québec Pension Plan.25 74 $4,274.18 $4.274.18 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3409 Débourses: Salaire du secrétaire.$1,960.00 Frais judiciaires.120.00 Trais de vérification.100.00 Impression, papeterie, acc.de bureau 240.00 Poste, téléphone, télégramme.35.00 A bonnement et publicité.145.00 Jetons de présence (membres du Comité).420.00 Frais de déplacements (membres du Comité).420.00 Frais de délégation.80.00 Assurance-groupe.206.88 Assurance-caution.10.00 frais d'affiliation.20.00 Rentes du Québec.51.48 «3,808.30 Excédent des recettes sur les déboursés prévu.$ 465.82 Disbursements: Secretary's salary.$1,960.00 Legal costs.120.00 Auditor's fees.100.00 Printing, stationery, ollice equipment 240.00 Postage, telephone, telegrams.35.00 Subscription and advertising.145.00 Attendance fees (Committee members),.420.00 Travelling expenses (Committee members).420.00 Delegation expenses.80.00 (iroup insurance.200.88 Fidelity bond.10.00 Affiliation fees.20.00 Québec Pension Plan.51.48 $3.808.36 Forecast surplus.$ 465.82 Le sous-ministre adjoint du Travail, Real Mireault.Ministère du Travail, Québec, le 22 juin 1968.25016-o Real Miueault, Ass/slant Deputy Minister of Labour.Department of Labour.Québec.June 22, 1968.25016-O Avis divers Miscellaneous Notices Andrew Uucban Cowe Avis est donné que Andrew Buchan Cowe instituteur, domicilié et résidant de la cité de l'orval, district de Montréal, province dc Québec, et résidant au numéro civique 357 avenue Court-land, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de « Andrew Buchan Cowan *.Montréal, ce 6iènie jour de juin, 1968.Les procureurs du requérant, O'Brien Home Hall Nolan l'1966-24-2-0 Saunders O'Brien & Smith.Joanna Amalia Haber Avis est donné que Roza Fried, ménagère, épuise de Rubin Fischer, épicier de la cité de Si Laurent, district de Montréal, s'adressera ai Lieutenant-gouverneur cn conseil de la province de Québec, afin d'obtenir que le nom de sa fille mineure, Joanna Amalia Haber, soit changé i u celui de Joanna Amalia Fischer.Montréal, 28 mai 1968.Le notaire, 24948-24-2 Robert Glazeh.Ronald Joscpli Adelstein Avis est donné que Ronald Joseph Adelstein, résidant à 2370, rue Gold, appartement \u2022107, en la cité de St-Laurent, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Ronald Joseph Malinoff; ledit changement de nom devra aussi servir à son épouse, née Susan Schwartz à la même adresse, et à son fils, né Bernard David Adelstein, aussi à la même adresse.Montréal, 7 juin 1968.Les procureurs, Chait, Aronovitch, Salomon, 24997-24-2 Gelber, Reis & Bronstein.Andrew Buchan Cowe Notice is given that Andrew Buchan Cowe teacher domiciled and residing in the City of Dorval, district of Montréal, Province of Québec and therein residing at 357 Courlland Avenue, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to that of \"Andrew Buchan Cowan\".Montréal, this 6th day of June, 1968.O'Brien Home Hall Nolan Saunders O'Brien & Smith, 24966-24-2-q Attorneys for petitioner.Joanna Amalia I labor Notice is hereby given that Roza Fried, housewife, wife of Rubin Fischer, grocer of the City of St.Laurent.District of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Quebec to have the name of her minor daughter.Joanna Amalia Haber, changed to Joanna Amalia Fischer.Montréal, May 28, 1968.Robert Glazer.24948-24-2-o Notary.Ronald Joseph Adelstein Notice is hereby given that Ronald Joseph Adelstein.residing at 2370 Gold Street, Apartment 307, in the city of St.Laurent, district of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Ronald Joseph Malinoff; said change of name shall also benefit his wife, born Susan Schwartz of the same address, and his son, born Bernard David Adelstein, also of the same address.Montréal, June 7, 1968.Chait, Aronovitch, Salomon, Gelber, Reis & Bronstein, 24997-24-2-0 Attorneys. 3470 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC.22 juin 1968.100' année, n° 25 Règles dc pratique dc la Cour supérieure dc la province de Québec cn matière dc divorce Établies en vertu de l'article 19 de la Loi sur le Divorce, 16 Elizabeth II, chapter 24.Dispositions générales 1° Sauf si elles sont incompatibles avec les présentes règles de pratique, les dispositions du Code dc Procédure Civile et les règles de pratique de la Cour supérieure, générales et spéciales, actuellement en vigueur, s'appliquent en matière de divorce, cn autant que faire se peut et en autant qu'elles ne contreviennent pas à la Loi du Divorce (16 Elizabeth II, chapitre 24) et aux règlements de divorce adoptés par le gouverneur en conseil cn vertu dc ladite Loi.2° À moins d'une disposition expresse de la Loi, le vice de forme n'emporte pas nullité sauf si le tribunal en décide autrement.Juridiction territoriale 3° Toute audition et toute enquête sur le fond de la cause ou sur une demande d'ordonnance provisoire ou sur un incident est faite devant le tribunal du lieu où la cause est continuée.4° Pour les fins du dépôt, île l'enregistrement, de la production, dc la vérification, de la réception d'une requête, dc la constitution du dossier, de l'examen de la procédure, des modes spéciaux de signification, du paiement des droits dc greffe, toute requête introductive dc l'instance en divorce doit se faire soit au greffe dc divorce du district de Québec, soit au greffe de divorce du district de Montréal scion le cas, conformément à la division des districts judiciaires indiquée à l'article 30 du Code de Procédure civile.5° Lorsque les délais prescrits pour la contestation sont expirés, le régistraire, sur demande écrite de l'une des parties, envoie le dossier au protonotaire du district judiciaire où la cause peut être appelée à se continuer selon les règles ci-après.6° Si le requérant réside dans la province de Québec, la cause peut être continuée devant le tribunal indiqué par lui dans sa requête, ù moins qu'il n'en soit décidé autrement par ledit tribunal sur la demande qui lui est soumise dans la contestation ou antérieurement à celle-ci; Si le requérant réside cn dehors de la province de Québec, la cause peut être continuée (levant le tribunal du district judiciaire dans lequel l'intimé réside ordinairement.Le régistraire 7° Le greffe des divorces, à Québec et à Montréal, est tenu par un officier appelé régistraire pour chacun de ces deux districts spéciaux délimités selon les dispositions de l'article 30 C.P.C.; ses devoirs sont les suivants: a) remplir ceux d'un protonotaire de la Cour supérieure tels que définis par le Code de Procédure civile, les règles dc pratique de la Cour supérieure et la Loi des Tribunaux judiciaires; 6) recevoir et enregistrer les requêtes après s'être rendu compte qu'elles sont conformes aux exigences de la Loi et des règles de pratique; c) rendre jugement sur les demandes interlocutoires dans le cas où il y a consentement des parties; Rules of Practice of the Superior Court of the province of Québec concerning divorce Enacted in virtue of section 19 of the Divorce Act, 16 Elizabeth II, Chapter 24.(Iencral provisions 1.Except insofar as they arc incompatible with the present Rules of Practice, the provisions of the Code of Civil Procedure and the Rules of Practice of the Superior Court, both general and special, presently in force, upply to divorce proceedings insofar as they are not inconsistent with the Divorce Act (16 KHz.II, c, 24).or with the Regulations as to divorce made by the Governor in Council under the said Act.2.Failing an express provision of law.no prcxecding shall be void merely because of a formal defect, unless the Court shall Otherwise determine.Territorial jurisdiction 3.Any proof ami hearing upon the merits of the ease, upon a demand for a provisional Order or upon an incidental proceeding takes place before the Court of the district where the case is continued.4.For purposes of filing, recording, checking, acceptance of a petition, constitution ol the record, examination of a pro,-ceding, special mode of service or payment of filing fees, any petit ion introductive of suit in case of divorce must lie made cither at the olfice of the Divorce Division of the Superior Court for the District of Qtiéhcc or at the office for the District of Montreal, as the case may lie, in accordance with the division of judicial districts set forth in Article 30 of the Code of Civil Procedure 5.When the delays for contestation have expired the registrar shall, upon the written request of one of the parties, send the record lo the protbonotary of the judicial district whin the case may l>e continued according to the rules hereinafter set forth.fi.If the petitioner resides in the Province of Québec the case may lie continued in the district designated by him in his petition unless the Court otherwise decides on a demand presented in the contestation or prior thereto.If the petitioner resides outside the Province of Québec, the case may be continued before the Court iu which the respondent ordinarily resides.The Begistrar 7.The office of the Divorce Division at Québec and at Montreal is administered by an ofliivr called the registrar for each of the two special districts defined by Article 30 C.C.P.; his duties are as follows: (a) to fulfill the duties of a protbonotary of the Sii|)crior Court as set forth in the Code ol Civil Procedure, the Rules of Practice of the Sii|)crior Court and the Courts of Justice Act: (b) to receive and register petitions after making certain that they conform to the requirements of the Divorce Act and of the Rules of Practice; (c) to render judgment upon interlocutory proceedings with the consent of the parties; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3471 il) expédier un dossier complet, avec inventaire des pièces, selon la règle 3 ci-dessus, au protono-taiiT du district où la cause doit se continuer; i i faire revenir à son greffe le dossier de chaque cause aussitôt qu'il cn a été disposé soit par avis de désistement, soit par rejet, soit par jugement irrevocable, ou qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le dernier errement; /) tenir un registre des procédures qui lui sont soumises indiquant particulièrement: 11 à l'égard de la requête, les noms et adresses de- parties, le lieu et la date dc sa production, de nièuic qu'un état sommaire des causes de divorce alléguées; 21 à l'égard du jugement irrévocable, les noms et adresses des parties, la date et le lieu où il a été prononcé, de même que l'indication de la cause ou des causes de divorce à la base du jugement; g) remplir les formules requises par les règlements sur le divorce établis par le gouverneur en conseil, et les expédier au bureau d'enregistrement des divorces à Ottawa, tel que prescrit par les règlements; h) requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il aura l'entière et unique responsabilité.8° Tout jugement et toute ordonnance rendus par le régistraire peuvent être revisés par le juge.Le protoiwtaire 0° Le protonotairc des districts autres que ceux de Québec et de Montréal reçoit les dossiers qui lui sont envoyés par le régistraire et, en sa qualité d'officier du tribunal, accomplit les fonctions habituellement dc son ressort selon le Code de Procédure civile, pour parvenir aux fins de la justice et mettre en oeuvre les objets et les dispositions de la Loi sur le Divorce.La requête 10° La requête, accompagnée d'un affidavit et d'un avis relatif à la contestation, doit être, cn autant que faire se peut, conforme à la formule annexée aux présentes règles.11° Toute requête en divorce doit être reçue et enregistrée par le régistraire avant d'être signifiée.12° Le régistraire a le droit de refuser de recevoir une requête et d'en permettre l'enregistrement s'il est convaincu que ladite requête ne répond pas aux exigences de la Loi sur le Divorce et des règles en vigueur.13\" Tout refus de la part du régistraire de recevoir et d'enregistrer une requête doit être motivé.14° Sur demande verbale, le refus du régistraire de recevoir et d'enregistrer une requête pour être revisé par le juge.15° Le requérant a le droit en tout temps de corriger sa requête de façon à obtenir qu'elle soit reçue et enregistrée, ou d'en présenter une nouvelle.16° Une copie conforme de la requête, après sa réception et son enregistrement, doit demeurer au dossier du greffe des divorces à Québec ou à Montréal, selon le cas.Signification 17° La requête doit être signifiée dans les 90 jours qui suivent la date de sa réception, sous peine de déchéance; néanmoins, pour des raisons (d) to send the complete record, with a list of exhibits, in accordance with Rule 5, to the protbonotary of the district where the case is to lie continued; (e) to have returned to his office the record of any case which has been disposed of by notice of discontinuance, dismissal or decree absolute, or where more than one year has elapsed since the last useful proceeding; (/) to keep a register of proceedings submitted to him containing: 1) for the petition, the names and addresses of the parties, the place and date of registration, together with a summary of the grounds of divorce alleged; 2) for the decree absolute, the names and addresses of the parties, the date and place where it was rendered, together with the ground or grounds upon which the decree was granted; (g) to fill out the forms required by the Regulations respecting the Divorce Act made by the Governor in Couneil and send them to the Central Divorce Registry in Ottawa as required by the said Regulations; (//) to obtain the personnel required for the proper carrying out of his duties, including assistant registrars, according to the number of proceedings filed in his office of which he sliall have the sole and complete responsibility.8.Any judgement or order of the registrar may be revised by the Judge.The Prothonotary 9.The prothonotary of a district other than Québec or Montreal receives the records sent to him by the registrar and, in his quality of officer of the Court, carries out the duties which are ordinarily bis under the Code of Civil Procedure in order to achieve the ends of justice and to carry out the purposes and provisions of the Divorce Act.The Petition 10.The petition, supported by an affidavit and a notice to contest, shall, as nearly as possible, be in accordance with Form 1 annexed to these Rules.11.Every petit ion for divorce shall be accepted for filing and registered by the registrar before being served.12.The registrar may refuse to accept a petition for filing or to permit it to be registered, if he is satisfied that the petition does not comply with the requirements of the Divorce Act and of the rules in force.13.Any refusal by the registrar to accept for filing or to register a petition must give reasons- 14.The refusal of the registrar to accept for filing or to register a petition may, upon a verba demand, lie revised by the Judge 15.The petitioner has the right at any time to correct his petition so that it may be accepted for filing and registered, or to present a new petition.16.A certified copy of the petition, after it lias been accepted for filing and registered, must remain in the record of the Divorce Office in Quebec or Montreal, as the case may be.Service 17.The petition must be served witliin 90 days following the date of its reception, under pain of nullity; before the expiry of such delay, 3472 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 26 jugées valables, ce délai peut être prolongé par le juge; toutefois, le juge, sur demande de toute partie intéressée, peut ordonner au requérant qui tarde à faire signifier la requête de le faire duns un délai imparti, sous peine d'annulation de la requête.18° La requête comporte un avis a la partie adverse de comparaître et de proposer en même temps tous moyens de contestation, accessoires, préliminaires, incidents ou de fond, dans les 20 jours d'une signification à personne dans la province de Québec; dans les 30 jours de telle signification ailleurs au Canada et aux États-Unis; dans les 40 jours d'une signification selon un autre mode autorisé par le juge sur requête, que ce soit dans la province de Québec, au Canada ou aux États-Unis; et dans les 60 jours ailleurs dans le monde selon le mode autorisé par le juge sur requête.Mesures accessoires 19° Nonobstant l'article 18, lorsque la requête introductive de l'instance cn divorce est reçue, toutes mesures acessoircs préliminaires ou incidentes peuvent être présentées avant l'expiration des délais prévus pour la contestation, sur requête au tribunal.Délais d'avis de présentation 20° Lorsqu'il n'est pas autrement prévu, toute demande au tribunal faite en vertu dc dispositions spéciales de la Loi sur le Divorce, se fait par requête avec avis de présentation dc cinq jours aux autres parties cn cause à moins que le juge n'en ordonne autrement.Frais 21\" Le tribunal peut en tout état de cause ordonner ù une partie de payer à l'autre si elle est sans ressources pécuniaires, une provision pour frais; il peut aussi prononcer condamnation aux dépens et alors les honoraires sont les mêmes que s'il s'agissait d'une action dc première classe du tarif dc la Cour supérieure, sauf le droit du tribunal d'augmenter ou de réduire ces honoraires sur demande à cet effet.Registres et droits de greffe 22° Les dossiers des affaires de divorce sont classifies séparément sous les directives du régis-truire qui en a seul la responsabilité; des registres, index, plumitifs et tous livres nécessaires sont tenus de même qu'un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement irrévocable de divorce.23° Lorsque îles dossiers sont expédiés par le régistraire aux protonotaires des divers districts, ceux-ci doivent les garder séparément, leur conserver le même numéro d'ordre, et les retourner au régistraire qui les leur a confiés, en y incluant les originaux de tous jugements, lorsqu'ils sont terminés, soil par désistement, soit par jugement de rejet, soit par jugement irrévocable, ou lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le dernier errement; il doit les retourner aussi sur demande du régistraire.24° les droits de greffe suivants sont payables sans délai : 1) sur présentation dc la requête en divorce, avant d'être reçue par le régistraire: $50; 2) sur comparution par un intimé ou un mis-en-cause: $25; upon verbal demand, for reasons which lie consider; sufficient, the Judge may extend this delays, nevertheless, the Judge may, on demand of any interested party order the petitioner who delays having service effected to have the petition served within such delay as be may fix, under pain of nullity of the petition.18.The petition contains a notice to the opposite party to appear, anil to present at the same time all his grounds of contestation, accessory, preliminary, incidental or on the merits, within 20 days of personal service in the Province of Québec; within 30 days of such service elsewhere in Canada or the United States; within 40 days of service by another mode of service authorized by a judge on petition, whether in the Province of Quéliec, in Canada or the United Slates; and within 00 days elsewhere iu the world according to a mode authorized by a Judge on motion.( 'orollary relief 19.Notwithstanding the provisions of Rule 18.once the petition has been received, any accessory, preliminary or incidental proceeding may.upon petition to the Court, be presented before the expiry of the delays for contestai ion.Delay for notice of presentation 20.Unless otherwise provided, every demand to the Court in virtue of the special provisions of Ihe Divorce Act is by motion with notice ol presentation of at least five days to the other parlies in the case, unless the Judge otherwise orders.('osts 21.The Court may at any state of the proceedings order a party to pay to the other if the latter is without i>ceuniary resources, a provision for costs; it can also order the payment of costs and then the fees are the same as in a first class action under the tariff of the Su|ierior Court, saving the right of the Court, proprio motu.to increase or reduce the fees in particular cases.Registers and fees of the court 22.The records in divorce proceedings are classified separately under the direction of the registrar who has the sole responsibility for them; registers, index, plumitives and all necessary books are kept as well as a special register available to the public in which is inscribed without delay every decree absolute of divorce.23.When the records are sent by the registrar to the prothonotaries of the various districts, the latter must keep them separately, maintain the same record number, and return them lo Ihe said registrar, including the originals of all judgments, when they have been brought to a conclusion either by discontinuance, by judgment of dismissal or by decree absolute, or it more than one year has elapsed since the last useful proceeding; he must also return them on demand of the registrar.24.The following fees of the Court are payable without delay: 1) upon presentation of the petition for divorce, before being accepted for filling by the registrar: $50; 2) upon presentation of an appearance by a respondent or mis-en-cause: $25; QUÉBEC OFFICIA E GAZETTE, .lune 22, 19GH, Vol.100, No.25 3473 3) upon an intervention: $25; if the intervention is made during the course of the suit after transfer of the record to the prothonotary of a district, the latter receives payment of the said fees, certifies having received the amount on the face of the intervention, and transmits it without delay to the registrar; 4) no other fees of the Court is exigible until after a decree absolute, even on seizures before judgment or orders of sequestration or other special proceedings, as the case may be; the fee of the Court includes a certified copy for each consort of the decree asbolute; 5) upon presentation of an inscription in appeal up to and including the transmission of the records to the office of the Court of Appeal: 825.June 7, 1968.We the undersigned, Superior Court Judges of the Province of Québec, have studied the Rules of Practice submitted for the purposes of the Divorce Act, and declare that these Rules and the amendments adopted at a meeting of Justices called for this purpose constitute the Rules of Practice to be followed in matters brought before the Superior Court in divorce proceedings, as our signatures attest.Frédéric DoRION, Jwjf en Chef\u2014 Chief Justice, Georges-S.Challies, juge en chef adjoint \u2014 Asso-rintc Chief Justice, Marcel Nichols, j.c.s., François AuCLAIR, j.c.s., (S.B.PudDICOMBB, j.c.s., Hii.liam Mitchell, j.c.s.Evender Veii.i.ei x.j.c.s., J.II.Hi.i mknstein, j.c.s., Maurice Ali iiarbault, j.c.s.FlIANÇOIS chevalier, j.c.s., andre DeMKHS.j.c.s., PlIll.lPPE LaMAHHE.j.c.s., André Nadeau, j.cs., Peter v.Shorteno, j.c.s., Guy M.Dbsaulniehs, j.cs*, Maurice Cousi-\\i id, j.c.s., André Montpktit, j.c.s., Paul Lksaok, j.c.s.Hector Pkhhieh, j.c.s., Iunace J.I)i -laiiRiERS, j.c.s., J.Brendan O'Connor, j.c.s., Claude Prévost, j.c.s., J.E.Mitchell, j.c.s., IV.A.Johnson, j.c.s.BERNARD be L.Bourgeois, j.c.s.Fkknand I.i'.iiai i.t.j.c.s.Albert Leblanc j.c.s., Edouard Tklmkh, j.c.s., Paul Trepanter, j.c.s., Philippe Pothier, j.c.s., Jacques Boucher,j.c.b., J.P.Charbonneau, j.cs.RouerOuimet, j.c.s., Harry Batshaw, j.c.s., Edouard Martel,j.c.s., Eugène Marquis,j.cs., William Mouin.j.c.s., Jean-Louis Marchand, j.cs,, Antoine Lacoiiicièhk.j.c.s.Jean-Rohkht BbaUOOIN, j.c.s., Rouer Laroche, j.c.s., gérard < oiiinvEAi .j.i-.s.Ciiarlks-A.Cannon, j.c.s., Edouard Laliberté, j.c.s., Gaiiiiiel Roberoe, j.c.s.Toi ssaint McNicoll, j.c.s.René Hamel.j.c.s., Pierre Let arte, j.c.s., Marcel Crête, j.c.s., Amhié Dude, j.c.s., Akthi rGendheau.j.cs.!l sur intervention: S25; si rintervention faite en cours d'instance après le transfert du -icr au protonotairc d'un district, celui-ci ¦il paiement dcsdils droits, certifie avoir reçu somme sur la face de rintervention.et la itsmel sans délai au régistraire; ; aucun autre droit «le grelfe n'est exigible jusqu'après jugement irrévocable, même sur les saisies avant jugement ou les ordonnances de séquestre ou autres procédures s|>éciales, le cas échéant; le droit de greffe comprend une copie Certifiée pour chaque conjoint du jugement irrevocable; sur présentai ion d'une inscription en appel jusqu'après la transmission des dossiers au grell'c de la Cour d'appel: $25.7 juin, 1968.Nous soussignés Juges de la Cour Supérieure île la Province dc Québec avons pris connaissance des règles tic pratique soumises pair les fins de la Loi du Divorce et déclarons que ces règles et les amendements adoptés en Assemblée des Juges convoqués à cette fin constituent les règles de pratique qui seront suivies dans les affaires portées ih vaut la Cour Supérieure cn matière dc divorce, selon que l'atteste notre signature.FORMULE I Requête en divorce < anada Province de Québec l'istricl de.Greffe des Divorces du District de.Montréal ou Quéliec) Ko A.B.(profession), (domicile) (dur Supérieure {Division des Divorces) requérant (c) vs C.I)., (domicile) intimé (e) l.iqiÊTE EN DIVORCE.AFFIDAVIT DU REQUÉRANT.DÉCLARATION DE L'AVOCAT, AVIS RELATIF À LA CONTESTATION ET CERTIFICAT m REOISTBAIBB Requête A l'honorable juge de la Cour Supérieure pour le district judiciaire de., la requête du lequérant expose respectueusement: 1.Je demande par les présentes au Tribunal de la Cour supérieure du Québec un jugement de divorce contre l'intimé, et en même temps (s'il 1) a lieu) une ordonnance m'accordaiit une iiension alimentaire, la garde des enfants et les dépens, pour les motifs exposés ci-dessous: FORM I Petition kir Divorce Canada, Province of Québec, District of.Superior Court, Divorce Registration Division of (Montreal or Québec).(Divorce Division) No.A.B.(Occupation), of the (domicile) Petitioner; vs C.D., of the (domicile) Respondent.Petition for Divorce, affidavit of petitioner, certificate of advocate, notice of contestation and certificate of registrar Petition To the Honourable Superior Court for the judicial district of., the petition of the petitioner respectfully represents: 1.I hereby petition the Superior Court of Québec for a decree of divorce from the Respondent and (if appropriate) for an order for alimentary pension, custody of children and costs, on the following grounds 3474 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n\" 20 Étal matrimonial el familial 2.Je suis né « .(endroit), le .jour de .19.l'intimé étant lui-même né ù .(endroit), le .jour de .19.3.J'ai é|x>usé l'intimé le.jour de.19.à (endroit), district de ., tel quC l'ut leste le certificat dc mariage produit comme pièce R-l (.s'il y a impossibilité de produire le certificat de mariage en indiquer la raison); 4.a) A la date du mariage, l'étal matrimonial des conjoints était le suivant: Pour moi-même.Pour mon conjoint.6) J'ai épousé l'intimé sous le régime de .(indiquer s'il s'agit ill hi corn mimante: \u2022 m dc la séparation de biens, et, s'il y a contrat de mariage, en prmluirc une copie authentique stiu.s la cote R-2); 5.J'ai eu de mon mariage à l'intimé les enfants suivants: (Donner ici les nom et prénoms dc chacun des enfants, arec indication de leur sexe et dc leur date de naissance); Domicile (art.5 et G de la Loi) 6.Je suis domicilié dans la province dc .et demeure présentement à qui est l'endroit de ma résidence depuis le .(indiquer la dale); cle son coté-, l'intimé est domicilié dans la province de où il demeure présentement à .(adresse), qui est l'endroit de sa résidence depuis le.(indiquer la date); (Si le domicile ou l'adresse de l'intimé est inconnu, l'indiquer); Matrimonial and Family status 2.I was born at.(place) on the .day of.19.and Respondent was born at.(place) (district of.) on the.day.of 19.3.I was married to the Respondent on tin .day of., at the.(place) as appears from a certificate as to such marriage filed as Exhibit R-l; (// the marriage certificate cannot be produced, so state and give reasons).4.(a) At the time of our marriage our marital status was For myself .For my spouse .(6) I married Respondent under the regime ol (indicate if there iras community or separation of property and if there was a marriage contract, file an authentic copy as Exhibit R.-2).5.There were born of our marriage the following children: (Here give the full names, sex.and dates of birth of all children); Domicile (Sections 5 and 6 of the Act) 6.1 am presently domiciled in the Province of.and reside at.(address) where I have resided since (date); the Respondent is domiciled iu the Province of.and resides ot.(address) where she has resided since.(date); (if Respondent's domicile or address are not known, so state).Motifs dc divorce 7.Les motifs pour lesquels je demande le divorce sont les suivants; (Donner ici le détail des causes de dirorce prévues aux articles 3 et J de la loi.en indiquant, dans le cas de l'article complété par l'article '¦).aliuia ¦>.la date, à laquelle les conjoints ont commencé ci vivre séparés l'un dc l'autre).Non-possibilité de reconciliation 8.J'ai tenté, en vue d'une reconciliation, les démarches suivantes: (En indiqutr le résultat après les aroir décrites): Mesures accessoires 9.Je demande la garde des enfants .(indiquer leur nom et prénoms) pour les motifs suivants: (Donner ici les raisons) 10.J'ai besoin pour moi-même et pour les enfants qui seront confiés à ma garde d'une somme globale dc 8.ou d'une pension alimentaire de $.payable cle la façon suivante (indiquer ici les modalités prérues aux articles 10 et 11 de la loi), cpie l'intimé est en étal de mc paver; Autres procédures 11.Il n'y a pis eu d'autres procédures d'intentées a l'égard de mon mariage (s'il y a eu des procédures en séparation dc corps ou de dirorce prises antérieurement, en donner tous les détails); Grounds for Divorce 7.The grounds upon which I base my Petition arc as follows (Here set fortli fully but concisely the grounds for divorce contained in Sections 3 and U of the Act.In the case of Section -5 ajr completed '»/ Section 9 (3) set forth the last place of cohabitation and the circumstances under which it ceased).Attempts at Reconciliation 8.The following efforts to reconcile have been made: (Describe efforts made and result thereof' Corollary Relief 9.I ask for the custody of the following children.(give the names) for the following reasons: (Here give reasons) 10.I need for myself and the children of whom I will be given the custody a total sum of $.or an alimentary pension of $.payable as follows: (criée here the mode of payment provided in Sections 10 and 11 of the Act which the Respondent is well able to pay me).Other Proceedings 11.There have been no other proceedings with respect to the marriage (here state all prior separation or divorce proceedings between the parties). QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, im.Vol.100, No.20 3475 13.(S'il // « lieu) II y a eu cependant entre l'intimée! moi-même un accord prévoyant l'aide niiili rii'llr rt le parlai;»- de» intérêts financiers uirl.2, alin.c ilo la loi); (en donner les détails).Absence de collusion et dc pardon |; Il n'y a eu aucune collusion ou connivence cul n l'intimé et moi-même en regard de la présente requête.14.Il n'y a eu aucun pardon des actes reproché- j| l'intimé.I'm u les motifs exposés ci-dessus, je prie le Tribunal de la Cour supérieure du Québec dc prot oticer un jugement dc divorce contre ['intimé et.(s'il y a lieu) dc rendre une ordonnance m'accordant les mesures accessoires suivantes: [Indiquer ici les mesures accessoires dont il a été question dans la requête).(Endroit et date) Requérant .l'indique le district dc.comme étant le district où la présente instance doit être continuée.(Régie 6) 12.(// appropriate) There bas been between the Respondent and myself an agreement providing for financial support and the division of properly interests.(Section 2 c of the Act); (Give details).Absence of Collusion or Condonation 13.There has been no collusion or connivance between the Respondent and myself in relation to this Petition.14.There has been no condonation of the grounds for divorce set forth in this Petition.Wherefore the Petitioner Prays: (a) That be be divorced from the Respondent; (b) (If appropriate) That by judgment he be granted the following corollary relief.(Sel forth the corollary relief requested in Ihe Petition) (Place and date) Petitioner I designate the district of.as the district where the case shall be continued (Rule 6).Requérant Affidavit (règle de pratique no 10) je, soussigné, A.Ii.(profession, domicile et résidence).déclare sous serment ce qui suit: I, Je suis le requérant (OU la requérante); J.J'ai pris connaissance de tous les faits allé- Blés dans la requête ci-dessus, lesquels sont vrais.l'.l j'.\\l SIliNÉ Petitioner Affidavit (Rule of Practice 10) I, the undersigned, A.B.(occupation, residing at address and coniciled at).(having been duly sworn do depose and say: 1.I am the Petitioner herein; 2.I have taken cognizance of the allegations in the foregoing Petition which are true.Asn i have bionbd Requérant (ou requérante) Assermenté «levant moi, re jour de.19.à (endroit) Commissaire à l'assermentation Déclaration de Tarocal Petitioner Sworn to before mc at the City of Province of this.day of.19.Commissioner for oaths Advocate's Certificate \u2022h-, soussigné.avocat du requérant (ou de la requérante), atteste avoir Nitisfuit aux exigences de l'article 7 de la Loi sur le «livorce.t.Endroit, date) I, the undersigned.attorney for Petitioner hereby certify tliat I have complied with the requirements of Section 7 of the Divorce Act.(Place and date) Avocat du requérant (ou de la requérante) Av il à l'intimé relativement à la contestation Prenez avis qu'il y a eu dépôt et réception au Kri-tre des divorces du district de.(Montréal ou Québec) dc la requête en divorce du requérant, et que si vous désirez la contes- Attorney for Petitioner Notice to Respondent as lo Contestation Take notice of the foregoing Petition and that it has Ik-cii presented to the Divorce Registrar for the Registration Division of (Quélicc or Montreal) and received by him. 3476 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n° 25 ter, vous devrez le faire en produisant une comparution ou votre contestation audit greffe, après leur signification au requérant, et ccdansles délais suivants: Dans un délai île 20 jours dc la date dc la signification de la requête, si telle signification vous a été faite à personne dans la province de Québec; Dans un délai de 30 jours de la date de la signification de la requête, si telle signification vous a été faite à personne ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique; Dans un délai de 40 jours, si telle signification de la requête ne vous a pas été faite à personne dans la province de Québec ou ailleurs au ( 'auada ou dans les États-Unis d'Amérique; Dans tous autres cas, dans un délai de 60 jours dc la date de la signification dc la requête, selon le mode autorisé par juge; Fkknkz dk plus avis qu'à défaut par vous de signifier et dépoter votre comparution ou contestation dans les délais susdits, le requérant procédera à obtenir contre vous, par défaut, un jugement dc divorce, accompagné de toute ordonnance accueillant les mesures accessoires qu'il sollicite contre vous; Piiknkz k.nkin avis que tout jugement rendu sera, cn premier lieu, un jugement conditionnel qui ne sera déclaré irrévocable qu'après l'expiration du délai fixé au jugement à moins «pie dans l'intervalle vous ne produisiez au grellic du Tribunal un avis écrit ex|k>saiit les raisons pour lesquelles le jugement ne devrait pas devenir irrévocable.(Endroit cl date) Avocat du requérant (ou de la requérante) Certificat du régistraire Je, soussigné, regislrairc du greffe des divorces pour le district de.(Montréal OU Québec) atteste qu'il y a eu reception et inscription au greffe de la requête cn divorce, de (affidavit du requérant (ou «le la requérante), de la déclaration de l'avocat ainsi que de l'avis à l'intimé relatif à la contestation.Montréal ou Québec, (date) Régistraire 25017-o Ville dc Val d'Or La requête dc: La Corporation Municipale dc la Ville de Val d'Or, corps politique et incorporé, ayant son bureau d'affaires en la Ville de Val d'Or et La Corporation Municipale de la Ville de Bourlamaque, corps politique et incorporé, ayant son bureau d'affaires en la Ville de Bourlamaque et La Corporation Municipale Lac Lemoyne, corps politique et incorporé, ayant son bureau d'affaires en la Municipalité de Lac Lemoyne Requérants.And further take notice that if you wi-h u, contest the said Petition, you must cause Ap|iea.ranee or Contestation to be served on Pel burner and filed in the Ollice of the Divorce Registrar at (address of Registrar's Office) within the following delays: If you are personally served within the Province of Québec within 20 days of the dale of such service; If you are personally served elsewhere in Canada, or the United States of America, within 30 days of the date of such service: If you are served but not personally within Québec or Canada, or the United State.Amen,.c within 40 days of the dale of such service; Otherwise, within 00 days of the date of service authorized by the Judge.And further take notice tliat in default of your serving and filing such Appearance or Contestation within the- time prescribed above, tin-Petit inner may proceed therein by default and a divorce decree and other relief may be granted without further notice to you.And further take notice that any decree gives in these proceedings will in the first instance Ik-a decree nisi that will not lie made absolute until the expiration of such time from (be pa line thereof as the decree may provide unies) ill the meantime you file in the Registry of this Court referred to above a written Notice that you wish to show cause why the decree should not become absolute.(Place and date) Attorneys for Petitioner Certificate of Registrar I.the undersigned, Registrar of the Division of the Superior Court for the District of .(Montreal or Québec) certify that there has been received anil filed in the said Divorce Division a petition for divorce, an affidavit of the Petitioner, a certificate of the advocate and a notice to the Rcspindcnt as to contestai JOB, Montreal or Québec (date) Registrar 25017-o Town of Val d'Or The petition of: The Municipal Corpiration of the Town of Val d'Or, corporation legally constituted bin ins its main oflice in the town of Val d'Or and The Municipal Corjioration of the Town of Bourlamaque, corporation legally constituted having its main ollice in the town of BounanUqUt and The Municipal Corpiration Lac Lemoyne corpiration legally constituted having its main office in the Municipality of Lac Lemoyne Petitioners. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, .Turn 22, 19G8, Vol.100, No.25 3477 Etpott respectueusement: ! Attendu que la Loi de la fusion volontaire des municipalités prévoit que les municipalités nui désirent se fusionner, peuvent adopter à la majorité absolue des membres de chacun de leur conseil, un règlement autorisant la présentation d'uni requête conjointe au lieutenant-gouverneur enconseil, le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité; 2° Attendu que les conseils dc vos requérants ont adopté un tel règlement; :', \\ tlcndu qu'un referendum tenu dans ces [rois municipalités a approuve à la majorité |l fusion volontaire proposée; Ks conséquence, vos requérants vous prient d'octroyer des lettres patentes fusionnant les mu 11 cipalités de Lac Lemoyne, Ville île Val d'Or et Ville de Hourlamaquc aux conditions suivantes: 1 À compter de l'émission des lettres patentes, la Ville de Val d'Or, la Ville de Hourlamaquc et la Municipalité de Lac Lemoyne formeront une corporation de Ville, connue sous le nom dc: «Ville de Val d'Or*; Le territoire de la nouvelle municipalité e-i celui «lécrit dans le plan dc l'arpenteur géomètre Victorien Sylvestre, portant le numéro A.1700 et daté du 1S mars 1968, et produit cn annexe de la présente pour en faire partie comme .'il était ici au long récité; 3) La nouvelle corporation sera régie par la Loi «les cités et villes et ses amendements, sauf les «'as auxquels les présentes lettres patentes dérogent spécialement, ou les dispositions incompatibles qu'elles peuvent contenir; I Les rôles d'évaluation, homologués et les taux de taxes foncières fixés par les rôles dc per-«eptiiui dans chacune des municipalités pour l'année 1968, demeureront cn vigueur jusqu'à la confection et l'homologation d'un nouveau râle «l'évaluation de tous les territoires créés par les présentes lettres patentes; 5i Tous les billets, bons, obligations, engage-mi'iiN, emprunts quelconques souscrits, acceptés, endossés ou consentis par In Mlle de Val d'Or, la \\ ille de llourlamaque et la Municipalité de Lac Lemoyne et actuellement cn force lors de rentrée en vigueur des présentes lettres patentes, continuent d'avoir leurs effets légaux et seront assumés par la nouvelle corporation créée parles présentes lettres patentes; 6 Sans préjudice aux clauses de taxation qui apparaissent dans lesdits règlements, la non .«'Ile corporation appropriera à même ses fonds généraux, les deniers suffisants pour pourvoir aux paiements des échéances des règlements suivants: Règlements de la Ville de Bourlamaque: Nos.90, 91, 96, 100, 102 et 103, 110, 113, 115: Règlements de la Municipalité Lac Lemoyne: «Vos.18 et 24, 38, 50, 53, 63; Règlements de la Ville de Val d'Or: Nos.118, 119, 142, 143, 144, 163, 172, 174.179, 184.201, 216, 217, 218, 219.296, 313, 327, 328, 329.339, 349, 354.300.367.371.372, 383.394.»95, 396, 398, 399, 405.422.425.430.440; î i La juridiction de la cour inuuieipale dc Val d'Or sera étendue ù tout le territoire de la nouvelle municipalité; Respectfully presents: 1.Whereas the law of voluntary amalgamation of municipalities states that the municipalities who desire to amalgamate, may pass by an absolute majority of the members of each of their councils, by-law authorizing the presentation of a joint petition lo the Lieutenant-Governor in Council, praying for the granting of letters patent amalgamating such municipalities and creating a new city.2) Whereas the councils petitioning have adopted such a by-law.3) Whereas a referendum held iu these three municipalities was approved in majority for the voluntary amalgamation proposed; Consequently, your petitioners pray that letters patent lie granted amalgamating the municipalities of Lac Lemoyne, Town of Val d'Or and Town of Hourlamaquc for the following conditions: 1) Immediately after the issuance of the letters patent, the Town of Val d'Or, the Town of Bourlamaque and the Municipality of Lac Lemoyne will form a Town (.'orporation, known under the name of \"Town of ValI d'Or\"; 2) The territory of the new municipality which is described in the plan prepared by land surveyor Victorien Sylvestre, bearing number A.1700 and dated March 18.1908, and filed in the annex of the present as a part of this petition.3) The new corporation will he governed by the Cities and Towns Act and its amendments, except in the cases where the present letters patent specially state, or the incompatible provisions that it may contain: 4) The homologated valuation roles, and the rale of prop-rty taxes set by Ihe collection roles in each of the municipalities for 1908 will remain in force up to the preparation and homologation of a new valuation role of all the territories created by the present letters patent; 5) All promisory notes, debenture, obligation, loans, liabilities accepted, endorsed or consented by the Town of Val d'Or, the Town of Hourlamaquc and the Municipality of Lac Lemoyne and effectively iu force when the letters [latent are granted will continue to have their legal effects and will be assumed by the new corporation created by the letters patent; 6) Without prejudice to the taxation clauses which apPCfif in the said by-laws the new corporation will appropriate within its general funds sufficent sums t.n en s'adressant pnr écrit à la Commission.Toute personne intéressée pourra prendre connaissance de ladite requête et cn obtenir copie aux endroits suivants: Motel de Ville de Val d'Or s\").\"), 2e Avenue, Val d'Or llêtcl dc Ville de Hourlamaquc Hourlamaquc IIntel de Ville de Lac Lemoyne 25 boni.Hôtel de Ville, Lac Lemoyne.25020-25-2-O 19) The mayor of the Town will be elected among the members of the council by the majority of member's present at the first meeting following the enforcement of the present letters patent.This meeting will be held the fifth legal day following the enforcement of the letters patent and will lie held at 8.00 p.m., at the place where the Town of Va! d'Or council regularly holds its meeting.If this meeting is not held on the said date the Minister of Municipal Affairs will i let ermine the dale of this first meeting as well as the manner of convocation.The property-owners of the petitioning municipalities who object to the amalgamation may, in the month following that during which the notice was published, make known the grounds of their objection, iu writing, to the Commission.All interested |iersons may study the said petition and obtain a copy at the following places: Val d'Or Town Hall 855, 2nd Avenue, Val d'Or Bourlamaque Town Hall Bourlamaque Lac Lemoyne Town Hall 25 Hotel de Ville Boulevard, Lac Lemoyne.25020-25-2-o l'aroisse Notre-Dame et Saint'Jacques Avis est donné conformément à l'article 2 de la loi des Fabriques (13-14 Elisabeth II chapitre 7'i que Son Excellence Monseigneur Paul Gré-uoire, archevêque catholique romain de Montreal, a, par un décret en date du 28 mai 1968, démenbré la paroisse de Notre-Dame de l'archidio-i ése de Mont réal et annexé la partie ainsi démembrée à la iwroisso île Saint-Jacques du même .m hidiocese.L'Areherèi/ue île Montréal, Paul Grégoire.j:,U89-o 17-08 Parish of .Notre-Dame and Saint-Jacques Nolicc is given pursuant to section 2 of the Fabrique Act (13-14 Elizabeth II.chapter 76) that His Excellency Monsignor Paul Grégoire, Roman Catholic Archbishop of Montreal, by a decree dated May 28, 1968, has dismemlicred the parish of Notre-Dame in the archdiocese of Montreal, and annexed the part so dismembered to the parish of Saint-Jacques in the same archdiocese.Paul Grégoire, Arclibinhop of Montreal.25089 17-68 \\ illage et paroisse de Nolrc-Duiiic-dii-Luc Comté île Témiseouata Avis est.par les présentes, donné qu'en dates du 11 et 12 juin 196S.les conseils municipaux du village de Notrc-Dame-du-Lac et de la paroisse dc Notrc-I)amc-du-I,ac, comté de Témiseouata.ont adopté un règlement pourvoyant à la Fusion de la municipalité du village dc Notre-I )amc-du-Liie et celle de la paroisse de Notre-I tame-du-Loc conformément à la loi de la fusion volontaire des municipalités.Ce règlement autorise la présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil, le priant d'octroyer des lettres patentes uuûonnant la municipalité du village dc Notre-l>uine-du-Lac et celle dc la paroisse de Notre-I ii nie-i lu -1 ,ae et créant une nouvelle municipalité désignée sous le nom de « Ville île Notrc-Dame-du-I.ipul.ition residing in this territory; 2.The town will be divided into three wards each comprising two seats. 3480 GAZETTE OFFICIELLE DE Ql'F.llEC, 22 juin 19i.fi, 100' année, n° 25 3° Jusqu'à 1» première élection générale, le conseil provisoire sera composé île tous les membres qui étaient cn fonction au moment de la fusion.Le maire sera désigné à la majorité des voix à la première séance du conseil provisoire.4° La première séance du conseil provisoire sera tenue le 2e lundi après l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à la salle du Centre «les loisirs à vingt heures.5° La date de la première élection générale sera le 1er lundi qui suivra le 90e jour de l'entrée en vigueur îles lettres patentes.La présentation des candidats aura lieu le 10e jour juridique précédant la dale de la premiere élection générale.La deuxième élection aura lieu le 1er dimanche de novembre 1971 et les élections générales subséquentes auront, lieu tous les trois ans le 1er dimanche de novembre.Il |>cut être pris connaissance du règlement dé-erétantjla fusion ainsi que delà requête conjointe au bureau des secrétaires-trésoriers de chacune des municipalités.Les propriétaires peuvent s'opposer à la fusion durant le mois qui suit celui des publications requises par la loi et faire connaître les motifs de leur opposition en s'udressant par écrit à la commission municipale.Hôtel du Gouvernement, Québec.Donné à Notrc-Dame-du-Lac.ce 13c jour du mois dc juin 19G8.Le secrétaire-trésorier, Jean-Guy Lavoie.La secrètaire-trésanère, 25088-25-2-o Mme Gabriel Ouellet.3.Until the first general election, the provi.sional council will l>e composed of all the members who were in ollice at the moment of amalgamation.The mayor will be appointed by the majority of the votes at the first meeting of the pro.visional council.4.The first meeting of the provisional conn, 1! will be held on the second Monday following the coming iido force of the letters patent.It will take place in the bull of the recreational center ul twenty hundred hours.5.The date of the first general election will be on the first Monday following the ninetieth day after the coming into force of the letters patent.The nomination of the candidates will take place on the tenth juridieial day preceding the date of the first general election.The second election will lake place on the first Sunday of November, 1971, and subsequent general elections will take place every three years on the lir-l Sunday of November, The by-law decreeing the amalgamation as well as the joint petition may be examined at tin office of the .secretary-treasurers of each of Ihe municipalities.The proprietors may make known their opposition (o the amalgamation during the month following the publications required by law, anil may make know n their relisons to such opposition by applying in writing lo the Municipal Commission, Parliament buildings, Québec, Given at Nolrc-Dame-du-Lac, this 13lb dav of the month of .lune, 100S.Jean-Got La voie, Secretary-Treasurer.Mrs.Gadiiiel Ouellet.25088-25-2 Sccielary-Trcasuier.Compagnies dissoutes Companies Dissolved A.C.I.Construction inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au minis! re des institutions financières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de charte dc « A.('.L.Construction inc.», constituée en coronation le 22 mars 1900.à compter du 15 juin 1908.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coapératires, Ls-Pllll.lH'e HoUCIIAUl).25015-o 1181-60 brook Itcalty Corp.Avis est donné qu'en vertu dc In Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives d'accepter l'abandon de charte de « H rook Really Corp.», constituée en corpiration le 27 février 1959.à compter du 15 juin 1908.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératires, Ls-Piiii.ippe BouciiAun.25015-o 11119-59 Le Capitule dc Chicoutimi inc.Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et COopérativea d'accepter l'abandon de charte de 1 I/' Capitale de Chicoutimi inc.».constituée en corporation le 20 novembre 1951.à compter du 15 juin 1008.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Ls-Piiii.i.ii'i'e HouciiAim.25015-0 14569-51 A.C L.Construction inc.Notice is given that, under the Companies Act.the Minister of Financial Institution-.Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"A C.L.Construction inc.\", incorporated on March 22.1906.on and from June 15.19(«.Ls-Phi i.i I'i'e Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperative' 25015 1181-66 It, uni, Realty Corp.Notice is given that, under the Companies Act.the Minister of Financial Inst i lut ion-.Companies and Coop-ratives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Brook Realty Corp.\".incorporated on February 27.1959, on and from June 15.1908.l.s-Pim.ii'pe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperative*.25015 11119-59 Le ( 'apitoie de Chicoutimi inc.Notice is given that, under the Companies Act.the Minister of Financial Institutions.Companies and CooiH'ratives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Le ( apitoie de Chicoutimi inc.\".incorporated on November 20.1951.on nnd from June 15.I90S.Ls-Pm i.i I'l-e Boi on Ann, /V put y Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.25015 14569-51 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, June 22.191,8.Vol.100.Xo.25 3481 J.II.Caron limitée Avis est donné qu'en VCrtÙ «le la I,oi «les com-MgllieSi il a plu au ministre «les institutions Bnai.cièrcs.compagnies el.coopératives «l'accepter l'abandon «le charte «le \u2022 .1.II.Caron limitée .constituée en eor|Hiration le 5 novembre 1052, à compter «lu 15 juin 1908.Ii .«us-ministre des institution.* financière*.compagnies d coopératives, Ls-PlIII.ii'pe H«H ( IIAKIl.23015-O 15086-52 Cliuleaii Muchincr\\ Corp.Avis esl donné qu'en vertu .1952.on and from June 15, 1968.Ls-Pllll.lPPE Hoi (uah II, Deputy Minister of Financial Institution.*.Companies and Cooperalire*.26015 1508(1-52 Chateau Machinery Corp.Notice is given that, under the Companies Act, I he Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender Of the charter of \"Chateau Machinery Corp.\u2022-.incorporated on February 4.1966, on anil from .lune 15.1908.Ls-Piiii.ippe Bouchard, De put// Minister of Financial Institution-*, Companies and Cooperalire.*.25015 491-06 Club «!«\u2022 lloekc> Itaie Conicuii inc.Club de Hockey Haie Comeuii inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et eoojicralives d'accepter l'abandon de charte «le « Club «le Hockey Baie Comeau inc.^, constituée en cor|ioratioii le 2 novembre 1966.à compter «lu 15 juin 1968.te tous ministre des institutions financières, com/Hignies et coopératires, I.s-PlIlI.ippe Bouchahd.250154 4487-06 Eaatslde Equipment Lui-Avis est donné qu'en vertu de la Loi «les compagnies, Il a plu au ministre des institutions tinau-riètes, coni|)ugiiics et coopératives «l'accepter l'abandon «le cliarte «le « Kastsidc Equipment Ltd, , «-«instituée en corpiration le 25 novembre 1957, à compter du 15 juin 1968.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératires, Ls-Piiii.ippe HouciiAiin.25111.-1.0 13745-57 Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and < ,'oo|x-ratives has liecn pleased to accc|il the surrender of the charter of \"Club de Hockey Baic C'omeau inc.\", incor|>oratcral ives d'accepter l'abandon de charte de « Douai l'aquin limitée .eouslituée en corporal ion le 3 mars 1927.à compter dû 15 juin 1908.I.e soux-miuistrc des iintitulions financières, compagnies rt coopératives, Ls-Phii.ippk Hoi i ii.Mii).25015-0 383-27 Keslaiirant au Passant inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi îles compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives d'accepter l'abandon dc charte «le « Restaurant au Passant inc.», constituée en corporation le 10 janvier 1984, à compter du là juin 1908./.c sous-ministre di s institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-l'iiu.il'i'i: bouchard.25015m 124-04 RockhUl Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a phi au ministre des institutions liiialieières, compagnies cl coopératives d accepter l'aliandon de charte de « Kockhill Holdings l.ld.¦¦.constituée en corporation le 3 décembre 1958, à compter du là juin 1908./.< sous-ministre des institutions financières, compagnies il coopératives, Ls-Piiii.ii'i'i: Bouchard.250154) 13027-58 Samuel Rcspitz Fur Corp.Avis est donné qu'en vertu de lu Loi des compagnies, il a plu au ministre dés institutions financières, compagnies et coop'rativcs d'accepter l'aliandon de charte de «Samuel Kcspitz Fur ' 'orp.».constituée en corporation le là avril 1955, i compter du 15 juin 1908./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.h'I'k Bouchard.250IS-o 1(1945-55 Kossy Knitting Mills Ltd.Avis est donné qu'eu vertu de la Loi des compagnies, il a plu au ministre îles institutions linancières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de charte de * Rossy Knilting Mills Ltd.'.constituée en corporation le 21 avril 1950, n compter du 15 juin 1908.I.c sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Ls-Pim.ii'pk Bough auh.25015-o 11238-56 Orion Films Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minislcr of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has liecn pleased to accept the Surrender of the charter of of \"Orion Films Ltd.\".ineorpirated on June 3, 1903.on and from June 15.1908.Ls-Piiiuppk Bouchard, Depot a Minister of financial Institutions.< ompanies and Cooperatives.25015 2385-63 Doiiut l'aquin limitée Notice is given that, under the ('ompanies Act, the Minister of Financial Institutions.Companies ami ('imperatives has liecn pleased lo accept the surrender of the charter of \"Donat l'aquin limitée\", incorporated on March 3.1927.on and from June 15.1968.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.25015 383-27 Restaurant au Passant inc.Notice is given that, under the Companies Act.I he Minister of Financial Institutions.Companies and Coop-nil ives has liecn pleased lo accept the surrender of the charier of \"Restaurant au Passant inc.\".incorporated on January 10, 1904.on ami from June 15.1908.Ls-PlIIUPPK Bill Cll Aid).Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.25915 121-04 Kockhill Holdings Ltd.Not ice is given 1 liai, under I he ( 'ompanies Act.the Minislcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has la-en pleased to accept I lie surrender of the charter of \"Roekhill Holdings Ltd.\".incorporated on December 3, 1958.on ami from June 15.1908.Ls-Piiilippe Boi.'CirARI), Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Coopérai ins.25015 13627-58 Samuel Kcspitz Fur Corp.Notice is given that, under the Companies Acl, the Minister of Financial Institutions, Companies and Coop-ratives bus been pleased to accept the surrender of the charter of \"Samuel Kcspitz Fur Corp.\".incorporated on April 15, 1955.on and from June 15.1908.Ls-Pmi.ippK Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, (ompanies and Cooperatives.25015 10945-55 Kossy Knilting Mills Ltd.Notice is given that, under ihe Companies Acl, the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has been pleased lo accept the surrender of the charier of \"Rossy Knitting Mills Lid.\", incorporated on April 21, 1950, on ami from June 15, 1968.I.s-Piin.i ppe Bough ah d, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.25015 11238-56 3484 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin HM18, 1(H)' année, n\" 25 St Germain, Malo, limitée Avis c-t donne qu'en vertu île la Loi îles compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de charte de « St Germain.Malo, limitée», constituée en corporation le 27 août 1026, à compter du 16 juin 1968.Le sous-ministre dc.i institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Hoichaud.26015m 1796-26 Solon Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'aiiep-ter l'abandon de charte dc < Solon Holdings Inc.», constituée cn corporation le (i mai 1955, à compter du 15 juin 1988.Le sous-ministre des institutions financières, com paon ie« et coopératives, Ls-Phii.iiti: bouchard.25015-o 11230-5.-) /.em Apartments Inc.A*in est ilonué qu'en vertu cle la Loi des compagnies, il a plu au ministre «les institutions finaiu ières.compagnies cl t oo|R:rat ives d'accepter l'aliandon de charte de < Zcm Apartments Inc.constituée cn corporation le 10 juin I95S, à compter du 15 juin 100*.Le .ions-ministre des institutions financières, compaon ies et coopératives, La-Pin lippe Bouchard.25915-0 12142-58 177 Holdings Inc.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et «oo|iérativcs d'accepter l'abandon de charte île « 177 Holdings Inc.», constituée en corporation le 9 avril 190\"), à compter du 15 juin 1968.Le sous-miiiistrc des institutions financières, compagnies et cunpréatires, Ls-Piiii.ippe Hoi chaud.2r.0l.Vo 1781-65 St Germain, Malo, limitée Notice is given that, under the Comps.Act.the Minister of Financial Institution-.Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"S| Germain, Malo, limitée\", incorporated on Atigu-i 27, 1920.on and from June 15, 190S.Ls-Piiii.ippe bouchabd, Deputy Minister f Financial Institut inns.Companies and Cooperatives.25015 1790-2(1 Solon Holdings Inc.Notice is given that, under the Companies Act.the Minister of Financial Institution-.Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Solon Hohlings Inc.\", incorporated on May o, 1955, on and from June 15, 1968.Ls-l'iiii.iiM'i: Bouchard, Deputy Minister of Financial Institution», Companies and Cooperatives.26016 11230-55 Zcm Apartments Inc.Notice is given ilia', under the Companies Act, the .Minister of Financial Institutions, Companies unci Coo|>eratives has liecn pleased to accept the surrender of the charter of \"/cm Apartments Inc.\", incorporated on June in.1958, on and from June lô.1968.I.s-l'iui.ii'pk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives.25015 121 12-.% 177 Holdings Inc.Notice is given that, under Ihe Companies Act, the Minislcr of Financial Institution-.Companies and Coo|ieralives has been pleased to accept the surrender of the charier of \"177 Holdings Inc.\", incori>orated on April 9, 190.'.on ami from June 15, 190S.Ls-Phii.ii'pk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.25015 1781-03 Chartes \u2014 Abandon de Charters \u2014 Surrender of I tor-iii.inc.La compagnie « Dorsin, inc., demandera incessamment au ministre des institutions linaucières, compagnies el coopératives la permission d'abandonner sa charte.I.c procureur, 25921-0 Me Paul Ciiarthai.v Hooper Realties (Mil.) Inc.Avis est par les présentes donné que « Hooper Realties (Mtl.) Inc.», incorporée en vertu de la Loi des compagnies, ayant le siège social dans la cite de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopérative- d'abandonner sa charte en vertu des dispositions «le la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 10 mai, 1968.Le président, 25023-0 A.Douglas Hooper.Dorsin, inc.The \"Dorsin, inc.\", company shall shortly ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender ils charter.Me Paul Charthaix, 25021 Attorney.Hooper Ileal ties (Mil.) Inc.Notice is hereby given that \"Hooper llealln (Mtl.) Inc.\", a corporation duly constituted under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and ( 'cooperatives for leave to surrender its (barter under the provisions of the Compaiiic Act.Dated at Montreal, this May 16, 1968.A.Douglas Hoopeu.25023-o President. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3485 Marcel Lapointe, inc.Marcel Lapointe, inc.La compagnie «Marcel Lapointe, inc.», demandera incessamment au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le -procureur, 25022-o Me Paul Chartrain.The \"Marcel Lapointe, inc.\", company shall shortly ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter.Me Paul Charthain, 25022-o Attorney.Hôpital general de la ville Pinard Hôpital general de la ville Emard Avis est par les présentes, donné que.la com- Notice is hereby given that the company pugnie « Hôpital général de la ville Kmard », \"Hôpital général de la ville Émard\", will apply .s adressera au ministre des institutions financières, to the Minister Financial Institutions, Com- compagpies et coopératives, pour obtenir une panics and Cooperatives for leave to surrender permission d'abandonner sa charte, conformé- its charter, pursuant to the Companies Act.ment aux dispositions de la Loi des compagnies.( e 7e jour du mois de juin 1968.This 7th day of the month of June, 1968.Le secrétaire, Dr.Robert Lemyre, 25024kl Dr Robert Lemyre.25024 Secretary.Lounge Esterai inc.Louage Esterai inc.Ksterel Leasing Inc.Estcrcl Leasing Inc.Prenez avis que « Louage Estére] Inc.\u2014 Notice is hereby given that \"Louage Esterai Ksterel Leasing Inc.», incorporée, en vertu de Inc.\u2014 Esterai Leasing Inc.\", will apply to la Iorntion G.A.N/\u2014 The (i.A.N.Corporation », a changé le nombre de SCI ailministratcurs dc 5 à 3.I.c secrétaire, F.mb.Lacroix.25035-o 4258-67 Baie-d'Urfé Yacht Club Notice is given that \"Baie-d'Urfé Yacht Club'' has changed the numlier of its directors from 6 to 12.H.P.Decker, Secretary.25031-O 4710-00 Baie-d'Urfé Yacht Club Notice is hereby given that Uie Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, on June 4, 1968, approved by-law number 13 (increasing the nubmer of its directors from 6 to 12) of \"Baie-d'Urfé Yacht Club\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Piiii.ippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.25031 4710-66 Code & Code Inc.Notice is given that \"Code & Code Inc.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.A.BlSSONNETTE, Secretan/.25034-o 14479-61 La Corporation G.A.N.The G.A.N.Corporation Notice is hereby given that \"La Corporation G.A.N.\u2014The G.A.N.Corporation\", has changed the number of its directors from 5 to 3.I-'.mi'; Lacroix, Secretary.25035 4258-67 Sliawinigan Industries Limited Les Industries Shawinigan.limitée Avis est donné que «Shawinigan Industries Limited \u2014 Les Industries Shawinigan, limitée », a changé le nombre «le ses administrateurs, de 11 à 15.Le secrétaire-trésorier, W.G.E.I.ann-am an.25036 196-63 Shawinigan Inilustries Limited Ia-s Industries Shawinigan, limitée Notice is given that \"Shawinigan Industries Limited \u2014 Les Industries Shawinigan, limitée\", has changed the number of its directors from 11 to 15.\\V.G.E.Lannaman, Secretary-Treasurer.25036-o 196-63 Le Jeune Commerce d«- Qiiélx-r, inc.Junior (Commerce of Quebec, lue.Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coojiératives a, le 3 juin 1968, approuvé les règlements généraux dc la corpiration « I.c Jeune Commerce de Quéliec, inc.\u2014Junior Commerce of Quebec, Inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.250374 3708-47 Le Jeune Commerce de Québec, inc.Junior Commerce of Quebec, Inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo]>era-tives has, on June 3, 1968, approved the general by-laws of \"Le Jeune Commerce de Québec, inc.\u2014 Junior Commerce of Quebec, Inc.\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.\u2022 Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.25037 3708-47 I'lomberie & Chauffage St-Bruno limitée at.Bruno Plumbing & Heating Limited Avis est donné que la compagnie « Plomberie & Chauffage St-Bruno limitée \u2014 St.Bruno Plumbing & Heating Limited », a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.secrétaire, A.Coulombs.25038-e 12735-61 Plomberie & Chauffage St-Bruno limitée St.Bruno Plumbing & Heating Limited Notice is hereby given tliat \"Plomberie & Chauffage St-Bruno limitée \u2014 St.Bruno Plumbing & Heating Limited\", has changed the number of its directors from 4 to 3.A.Coulombe, Secretary.25038 12735-61 3488 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin J968, 100' année, n\" 25 Bovimpoii Inc.Avis est donné que « Bovimport Inc.», a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 à 7./.c président, A.de Moustier.25032 2120-0.r> Suabiun Corporation Avis est donné que « Swabiun Corporation », u changé le nombre dc ses administrateurs, de 7 à 15.Le secrétaire, Andrew Feller.25039 11007-00 Centrale d'Artisanat du Québec Quebec I laud ici all Centre Avis est donné que le secrétaire de la province a, le 10 mai 1968, approuvé le règlement spécial numéro 1 - 1968 dc la corporation « Centrale d'Artisanat du Québec - \u2014 Quebec Handicraft Centre », et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.la sous-secrétaire de la province, Raymond Douvii.i.i;.25044-o 1846-50 Établissement M area-il Avis es! donné que, par nouvelle procuration en date du 18 mars 1908, dont une copie a été transmise au secrétaire de la province, M.Castellani Manlio, gérant.201.rue St-Zotiquc est, Montréal, a été nommé, en remplacement de M.Sergio Tueci.agent principal dans la province, d'« Établissement Marcasit », compagnie étrangère, dûment autoriser à faire affaires dans la province de Québec cn vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Avis est aussi donné qu'en vertu de la nouvelle procuration ci-haut mentionnée, le bureau principal i>cratives oj the Province, ROC er-a C a m All airi :, 25075-25-2-O Superintendent of Insurance.Fonds de Secours des Forestiers Catholiques de lu Province de Québec Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"Fonds de Secours des Fonciers ( 'atholiques dc la Province de Québec\" has ceased to do business; Whereas \"Fonds de Secours des l'on -tier* Catholiques de la Province de Québec\" lias Bled with the Insurance branch a declaration to the circct that on the June 12 1968, it had no assets and no liabilities, having distributed its surplus lo its members after having discharged all its debts; Therefore, notice is hereby given that the license and ccrtilicate of registry of \"Fond» de Secours des Forestiers Catholiques «le la Province de Québec\" arc cancelled as from the June 15, 1968.Given at the ollice of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the June 15, 1968.For the Minister of Financial Institutions, Companies and ( 'imperatives of the Province, RooBB-A.Camaraiiii:.25076-25-2-0 Superintendent of Insurance.Compagnie d'Assurance Mutuelle «\u2022outre le Feu de la Puroisse de Sainl-Gcorgi's de Windsor, County of Richmond Notice of Cancellation of License and Registration Whereas \"La ( 'oinpngnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu dc In Paroisse de 8t-Ge©rges de Windsor, county of Richmond\", has ceased to do business iu the Province of Québec as from the 31st of December 1967; Whereas the president and the secretary-treasurer of the said company has filed, on the 29th of May 1968, with the Insurance branch, a sworn declaration to the effect that the company has cancelled all its policies, having no more debts nor surplus to be distributed; Therefore, notice is hereby given that the license and registration of \"La Compagnie d'Assll-ranec Mutuelle contre le Feu de la Paroisse de St-Georges de Windsor, county of Richmond', are cancelled as from the 1st of June 196S.Given at the office of the Insurance Brandt, Department of Financial Institutions, Compagnies and Cooperatives, the 1st of June 190s- For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Rooer-A.Camaraire, 25052-25-2-o Superintendent of Insurance. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 19G8, Vol.100, No.25 3497 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Municipalité de Bcrnibrcs Avis est donné par les soussignés que le lieutenant-gouverneur en conseil a adopté, en date du 5 juin 1968, un arrêté en conseil ayant pour objet de changer le nom de la paroisse de Saint-Nicolas-Sud, comte de Lévis, en celui de « Municipalité de Ilernières ».Conformément à l'article 48 du Code municipal, ce changement de nom entre en vigueur à compter de la publication du présent avis dans In Ilazette officielle de Québec.St-Xicolas-Sud, le 14 juin 1968.Le maire, Roger Landry.Le secrétaire-trésorier, Roger Noël.26086-o Val-Saint-Gilles Le soussigné donne avis que, tel que demandé dans une résolution adoptée le 1er juin 1968 par le conseil municipal dc Val-Saint-Gilles, comté d'Abin'bi, et conformément il l'article 130 du Code municipal, il a décrété, cn date du 13 juin 1968, que les publications dc tout avis pu-Idic, règlement, résolution ou ordre tie la corporation dc Val-Saint-Gillcs, sauf celles requises dona la Gazelle officielle de Québec, se feront à l'avenir dans la langue française seulement.Le présent avis est publié en vertu de l'article 131 du Code municipal.Québec, le 13 juin 196S.la sous-ministre des affaires municipales, -MOôl-o Jean-Louis DotTCET, en.Ville de Suinte-Annc-de-Bellevue Avis est donné que, par l'arrêté en conseil No 1694 du 5 juin 1968 et conformément à l'article 13 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver le règlement No 256 du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-de-Hellevue et de décréter que, à compter dc la date de la publication du présent avis, le territoire mentionné audit règlement et décrit ci-dessous est détaché de la ville de Baie-d'Urfé et annexé à la ville de Sainte-Anne-de-Bcllevue.Ce territoire est le suivant: Un territoire faisant actuellement partie de la \\ i 1 le dc Baie d'Urfé et comprenant en référence au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne, dans la division d'enregistrement de Montréal, les lots 299, 300 et 301 ainsi que la partie du lot 304 limitée comme suit: au nord par le côté sud d'un chemin public (rue Sainte-Anne) sur une distance de 380' à partir du point d'intersection dudit côté sud avec la ligne separative des lots 304 et 305, à l'est par ladite ligne separative de lots, au sud par la rivière des Outaouais et à l'ouest par une ligne parallèle à la ligne separative des lots 304 et 305 et située à 380' d'icelle; lequel territoire à être détache de la municipalité de la ville de Baie d'Urfé pour être annexé à la ville de Sainte-Annc-de-Bellevue.Le sous-ministre des affaires municipales, 25051-o Jean-Louis Doucet, c.r.Municipality of Bernibres Notice is hereby given by the undersigned that the Lieutenant-Governor in Council has adopted on June 5, 1968, an Order in Council having for purpose to change the name of the parish of Saint-Nicolas-South, county of Levis, to that of \"Municipalité of Bcrnières.\" Pursuant to section 48 of the Municipal Code, this change of name becomes effective from and after the publication of the present notice in the Québec Official Gazette.Saint-Nicolas-South, June 14, 1968.Roger Landry, Mayor.Roger Noël, 25086 Secretary-Treasurer.Val-Saint-Gillcs The undersigned gives notice that, as requested in a resolution adopted on June 1, 1968 by the municipal council of Val-Saint-Gilles, county of Abitibi, and pursuant to section 130 of the Municipal Code, be has enacted, on June 13, 1968, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the corporation of Val-Saint-Gilles, save those required in the Quebec Official Gazette, will be made, henceforth, in the French language only.This notice is published pursuant to section 131 of the Municipal Code.Québec, June 13, 196S.Jean-Louis Doucet q.c., 25051 Deputy Minister of Municipal Affairs.Town of Sainte-Anne-dc-Bcllevue Notice is hereby given that by Order in Council No.1694 dated June 5, 1968, and in conformity with section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve by-law No.256 of the municipal council of the Town of Saintc-Annc-de-Bellevue and to decree that, from and after the date of the publication of the present notice, the territory mentioned in the said by-law and described hereunder is detached from the Town of Baie-d'Urfé and annexed to the Town of Sainte-Annc-de-Bellevue.This territory is the following: A territory actually being part of the Town of Baie d'Urfé and including in reference to the official cadastre of the parish of Sainte-Anne, in the registration division of Montreal, lots 299, 300 and 301 as well as part of lot 304 limited as follows: on the north by the southern side of a public road (Sainte-Anne Street) on a distance of 380' starting from the intersection point of the said southern side with the separative line of lots 304 and 305, on the cast by the said separative line of lots, on the south by Outaouais River and on the west by a 1 ine parallel to the separative line of lots 304 and 305 and situated at 380' of these; the said territory to be detached from the municipality of the Town of Baie d'Urfé to be annexed to the Town of Sainte-Anne de-Bellevue.Jean-Louis Doucet, q.c, 25051 Deputy M mister of Municipal Affairs. 3498 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1988, 100' année, n° 25 Ministère de l'Éducation Department of Education Collège d'enseignement général et professionnel dc Jolicttc Avis est donné qu'en vertu de l'article ;i de la Loi des collèges d'enseignement général el professionnel, 15-16 Elizabeth II, chapitre 71, des lettres patentes ont été accordées le 27 mai 1968, constituant en corporation: Le Collège d'enseignement général et professionnel dc Joliette.Ije sous-ministre de l'Éducation, 25070-o Arthur Tremblay.Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette N'otice is hereby given that under section 3 of the (iencral and Vocational Colleges \\,|.15-16 Elizabeth II, chapter 71, letters pal-ni were granted on May 27, 196S, incorporating; Le Collège d'enseignement général et professionnel de Joliette.Arthur Tremblay, 25070 Deputy Minister of Education, Nominations Appointments Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commissions sous le grand sceau dc la province, les nominations suivantes: Québec, le 14 février 1968.M.Michel Marcotte, médecin, de Colcau-du-Lac, coroner jxnir le district judiciaire de Montréal, avec juridiction seulement sur le district électoral de Soulanges.24-6.8 Notice is hereby given that the Lieutenant\" Governor in Council has been pleased to make' by Commissions under the Great Seal of the Province, the following appointments: Québec, February 14.190s.Mr.Michel Marcotte, doctor, of Cotcau-du-LaCi coroner for the judicial district of Montreal, with jurisdiction only on the electoral district of Soulanges.24-68 Québec, le 20 mars 196s.M.Gaston Tremblay, médecin, de La Tuque, coroner suppléant sur le territoire du district électoral dc Laviolette seulement pour le district judiciaire de St-Maurice, et sur le territoire du district électoral de Cbauveau seulement, qui comprend les cantons de biart, Bickerdikc, liorgia.Chasseur, Chaumonot, Gendron, Laure, Lavoie, Tescarbot,'Michaud, Papin, Perrault.Trudcl et Rhodes, pour le district judiciaire dc Québec 34-68 Québec, le 3 avril 1968.M.Louis-Joseph bacband, médecin, dc Saint-Joscpb-du-Lae, coroner suppléant pour le district judiciaire de Terrebonne, avec juridiction seulement sur le district électoral des Deux-Montagnes.38-6S Québec, March 20.190s.Mr.Gaston Tremblay, doctor, of La Tuque, assistant coroner on the territory of the electoral district of Laviolette only for the judicial district of St-Maurice.and on the territory of the electoral district of Cbauveau only, which includes the townships of Biart, bickerdikc.Borgia, Chasseur, Chnutnonot, Goudron, Laure, Lavoic, l.escarbot, Michaud.Papin, Perrault, Trudel and Rhodes, for the judicial district of Quebec.34-68 Québec, April 3, 1988, Mr.Louis-Joseph bacband.doctor, of Saint -Joseph-du-Lae, assistant coroner for the judicial district, of Terrebonne, with jurisdiction only on the electoral district of Two Mountain-.38-08 Québec, le 3 avril 1968.M.Jacques Bergeron, médecin, de La Tuque, coroner avec juridiction sur le territoire du district électoral de Laviolette seulement, sur le district judiciaire de St-Maurice, et sur le territoire du district électoral de Cbauveau seulement qui comprend les cantons dc biart, Bickerdikc, Borgia, Chasseur, Chaumonot, Gendron, Laure, Lavoie, Lcscarbot, Michaud, Papin, Perrault, Trudel et Rhodes, pour le district judiciaire dc Québec.39-68 Québec, le 25 avril 1968.M.L.-G.Bolduc, médecin, dc Scnneterre, coroner pour le district judiciaire d'Abitibi avec juridiction seulement sur le district électoral d'Abitibi-Est.Québec, April 3, 1968.Mr.Jacques Bergeron, doctor, of La Tuque, coroner with jurisdiction on the territory of the electoral district of Laviolette only, on the judicial district of St-Maurice, and on the territory of the electoral district of Chauvcau only which includes the townships of Biart, Bickerdikc, Borgia, Chasseur, Chaumonot, Gendron, Laure, Lavoie, Lescarbot, Michaud, Papin, Perrault, Trudcl and Rhodes, for the judicial district of Québec.39-6S Québec, April 25, 1968.Mr.L.-G.Bolduc, doctor, of Scnneterre.coroner for the judicial district of Ahitibi with jurisdiction only on the electoral district 01 Abitibi-East.Le sous-secrétaire dc la province, Raymond Douville.25015-o 46-68 Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 46-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3499 Avis est donne que, par arrêté en conseil numéro 340, en date du 14 février 1968, il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil dc nommer M.Pierre-E.T.Bcaudry, avocat et membre du barreau du Québec, conseil cn Loi de la reine.Le sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.2ô(I15-o 1-68 Notice is hereby given that, by Order in Council number 340, dated February 14, 1968, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to appoint Mr.Pierre-E.T.Bcaudry, advocate and member of the Québec bar, Queen's Counsel learned in the law.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 1-68 Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-piiiverneur en conseil de faire, par commissions sous le grand sceau de la province, les nominations suivantes: Quebec, le 14 février 1968.M.Jacques Langis.médecin, de Disraeli, coroner pour le district judiciaire de Saint-François, avec juridiction seulement sur le district électoral de Wolfe.23-68 Québec, le 20 mars 1968.M.Claude Besner, médecin, de Maniwaki, coroner suppléant pair les districts judiciaires de Labelle, Pontine, Abitibi et Joliette, sur les territoires expressément mentionnés dans l'arrêté en conseil portant le numéro 657, du 20 mars I96S.£5-68 Québec, le 17 avril 1968.M.François Soucy, médecin, de Drummondville, coroner suppléant |»ur le district judiciaire de Drununond.avec juridiction seulement sur le district électoral de Drununond, I^e sous-secrêtaire de la province, Raymond Douville.25915-0 42-68 Notice is hereby given that the Lieutenant-Governor in Council was pleased to make, by Commissions under the Great Seal of the Province, the following appointments: Québec, February 14, 1968.Mr.Jacques Lungis, doctor, of Disraeli, coroner for the judicial district of Saint-François, with jurisdiction only on the electoral district of Wolfe 23-68 Québec.March 20, 1968.Mr.Claude Besner, doctor, of Maniwaki, assistant coroner for the judicial districts of Labelle, Pontine, Abitibi and Joliette, on the territories expressly mentioned in Order in Council number 657 of March 20, 1968.35-68 Québec, April 17, 1968.Mr.François Soucy, doctor, of Drummondville.assistant coroner for the judicial district of Drununond, with jurisdiction only on the elcctorul district of Drummond.Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.25015 42-68 Régie des Marchés Québec Agricultural Agricoles du Québec Marketing Board Projet de plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (Section II) Correction A cause d'une erreur cléricale, le paragraphe premier (1 °) du règlement relatif au referendum tenu pir la Régie des marchés agricolesdu Quéhcc en marge du projet de plan conjoint des producteurs de bois des Lan rent nie.(Section II), paru dans la Gaulle officielle de Québec le 18 niai 1968, vol.100.no 20, doit être corrigé en le remplaçant par le suivant: « 1° Pour être considéré comme un producteur intéressé, au sens de l'article 25 de la Loi des marchés agricoles et avoir voix au référendum tenu |»r la Régie cn marge du projet de plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (Section II), il faut être possesseur, à quelque titre que ce soit, d'un boisement couvrant une superficie de dix (10) acres et plus, sis dans les comtés municipaux de Terrebonne et Deux-Montagnes et les lies dc Montréal.Jésus et Hizanl et mettre ce produit en marché; les détenteurs de permis de cou|>c émis par le ministère des Terres et Forêts «le la province de Québec sont toutefois exclus pour le bois coupé en vertu de ces permis.» Montréal, le 6 juin 1968.Le secrétaire intérimaire, 25081-o Rocu Morin.Draught of a Joint Plan of wood producers of the Laurentides (Section II) Correction On account of a clerical error, the first (1) paragraph of the by-law relative to the referendum held by the Qiu'diee Agricultural Marketing Board on the Draught of a Joint Plan of wood producers of the Laurentides (Section II), having appeare«l in the Quebec Official Gaulle of May 18, 1968.Vol.100, No.20, must be corrected by replacing it by the following: \"1.To be considered an interested producer in the sense of section 25 of the Agricultural Marketing Act, ami to have a vote in the rc-ferendum held by the Board on the draught of the joint plan of wood producers of the Laurentides (Section II), one must be the owner, for any purpose whatsoever, of a wood lot covering an area of ten acres and more, situated in the municipal counties of Terrebonne and Two-Mountains and the Islands of Montreal, Jesus, and Bizard and market this product; the holders of cutting licenses issued by the Department of Lands and Forests of the Province of Québec are, however, excluded for the cut wood pursuant to these licenses.Montreal, June 6, 1968.Rocu MoniN, 25081 Interim Secretary. 3500 GAZETTE OFFICIELLE DE QlEllEC, 22 juin 1908, 100' année.n° 2,r, lr Syndicat des producteurs de lait nature du comté de Richmond (U.C.C.) Suite à la décision rendue par la Régie des marchés agricoles du Québec le 1er février 1967, mettant fin au plan conjoint des producteurs de lait nature du comté dc Richmond, le liquidateur, nommé par rassemblée générale des producteurs iidéressés, a déposé son rapport final.Les états financiers de liquidation ont été acceptés el approuvés par les producteurs au cours d'une assemblée spéciale et par la Régie des marchés agricoles du Québec.Prenez avis en conséquence que le Syndicat des Producteurs dc lait nature du comté dc Richmond (U.C.C.) a terminé l'administration du plan conjoint des producteurs «le luit nature du conité «le Riclmiond.Montreal, ce 29 mai 1968.Régie des Marchés agricoles du Québec.Li président.Maurice Halle.Le secrétaire-intérimaire, 25081-o Rocu Moins-.The Raw Milk Producers Syndicate of the County of Richmond (U.C.C.) Following the decision rendered by the Québec Agricultural Marketing board on February 1.1967, putting an end to the joint plan of raw milk producers of the county of Richmond, the liquidator, appointed by the general assembly «>f interested producers, tlejiositcd his final report.The liquidai ion financial statements were accepted and approved by the producers at a special assembly and by the Québec Agricultural Marketing board.Therefore take notice that The Raw Milk I'roduecrs Syndicate of the County of Richmond (U.C.C.) put an end to the administrai ion of the joint plan of raw milk producers of the county of Richmond.Montreal, May 29.1908.Québec Agricultural Marketing board.Maurice Halle, President.Rocn Moiux, 250S1 Interim Secretary.Ministère des Terres et Forêts Department of Lands and Forests Cadastre Cadastre Canton dc Harrington Cadastre officiel du canton de Harrington, municipalité du canton de Harrington, division «l'enregistrement de Argenteuil.Avis est par la pr«Vsente donné que les lots 7-B-26 à 7-H-29.7-11-32, 7-B-33 rang VII et les lots 7-B-2 à 7-B-4 rang VIII sont annulés cn vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 5 juin 1968.IjC sous-ministre, 25053-o Fernand Boutin.Paroisse dc Ste-Foye Cadastre olficicl de la paroisse «le Ste-Foye, municipdité de la Cité dc Stc-Foy, division d'enregistrement de Quél>cc.Avis est pir la présente donné que le lot 51-2 est annulé en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 12 juin 1968.Le sous-ministre, 25053-o Fkiinand Boutin.Paroisse de Stc-Julie Cadastre officiel de la paroisse de Sic-Julie, municipalité dc la paroisse dc St-Amable, division d'enregistrement «le Vcrchèrcs.Avis est pir la présente donné que le lot 194-6 est annulé cn vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 juin 1968.Le sous-miitistre, 25053-o Fernand Boutin.Paroisse de Stc-Thérèse «le bluim ille Cadastre olficicl de la paroisse de Ste-Thérèse de Blainville, municipalité de la Cité «le Ste-Thérèse, division d'enregistrement «le Terrelxmne.Avis est par la présente donné que les lots 553-414 a 553-418, 553-422, 553-539 ù 553-546, 554-403 à 554-408 et 554-411 sont annulés cn vertu «le l'article 2174A du C«xlc civil.Québec, le 7 juin 1968.Le sous-mi n islrc, 25053-o Fernand Boutin.Township of Harrington Official cadastre of township of Harrington, municipality of township of Harrington, registration division of Argenteuil, Notice i> bercbv given that lots 7-11-20 to 7-B-29, 7-11-32, 7-11-33 Range VII and the lots 7-B-2 to 7-11-4 Range VIII are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, June 5, 1968.Fernand Boutin, 25053-o Deputy Minister.Parish of Ste-Foye Official cadastre of the parish of Ste-Foye, municipality of the City of Stc-Foy, registration division of Québec.Notice is hereby given that lot 51-2 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec.June 12, 1968.Fernand Boutin, 25053-o Deputy Minister.Purisb of Ste-Julic Official cadastre of the parish of Stc-Julie.municipality of the parish of St-Amable, registration division of Vcrchèrcs.Notice is hereby given that lot 194-6 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, June 7, 196S.Fernand Boutin, 25053-o Deputy Minister.Parish of Ste-Thérèse de Blainville Official cadastre of the parish of Ste-Thérèse de Blainville, municipality of the City of Sic-Thérèse, registration division of Terrebonne.Notice is herehv given that lots 553-414 to 553-418.553-422, 553-539 to 553-546, 554-403 to 554-408 and 554-411 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, June, 7, 1968.Fernand Boutin, 25053-o Deputy Minister. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, J9G8, Vol.10O, No.25 3501 Ministère cle l'Industrie Department of Industry et du Commerce and Commerce Loi sur les pêcheries Règlement de pêche du Québec Avis de pêche aux coques Vu la décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social à l'effet que les coques des régions coquillèrcs situées le long des côtes et des eaux: N-1.1 région s'étendant de Pointe Laval - Pointe Orient (en ligne avec le pont de Rivière Laval) sont toxiques à un point qui les rend dangereuses pour la consommation à l'êtal cru.À ces causes et conformément à l'article 6, piragraphe 1, du règlement île pêche du Québec, par les présentes, il phitt au ministre de fermer lesdites régions à la pèche et d'interdire à quiconque de pêcher, de prendre ou d'avoir en sa possession des coques provenant desdites régions.La présente interdiction ne s'applique pas ce pendant aux producteurs licenciés (Arrêté en Conseil Québec 1963-779) pour la mise en conserve seulement.Québec, le 12 juin 19G8.Le minisire dc l'Industrie cl Commerce, 25071-o Jean-Paul Beau dry.Divers Compagnies Institut Philippe Pinel de Montréal Avis est donné que la corporation « Institut Philippe Pinel de Montréal \\ a changé le nombre de ses administrateurs tie 5 à 10.Le président, Hun n i M asson-Loranc; f.k .2.,D99-0 2570-68 Institut Philippe Pinel de Montréal Avis est donné que le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives a, le 19 juin 19CS, approuvé les règlements numéros 1, 2, 3ct4 de la corporation « Institut Philippe Pinel de Montréal », et ce, en vertu de l'article 225 tic la Loi des compagnies.I.i sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PiiiLii'i'e Bouchard.25099-o 2576-68 Fisheries Act Québec Fishery Regulation Notice of Clam Fishing Iii view of the tlccision rendered by the Minister of National Health and Welfare to the effect that clams iu shellfish areas situated along the shores and waters: N-4.1 region extending from Pointe Laval-Orient (in line with the Laval river britlge) are toxic to a degree unsafe for use as a raw food.Therefore, pursuant to section 6, paragraph 1 of the Québec Fishery Regulation, the Minister is hereby pleased to close the said areas to fisliing and to forbitl whomsoever to fish, to take or to have in his possession clams from the saitl areas.This interdiction does not apply, however, to licensed producers (Order in Council Québec 9G3 779) for canning purposes only.Quebec, June 12,19G8.Jean-Paul Beau dry, 25071 Minister of Industry and Commerce.Miscellaneous Companies Institut Philippe Pinel de Montréal Notice is hereby given that \"Institut Philippe Pinel de Montréal\", bas changed the number of its tlircctors from 5 to 10.Henri Masson-Loranger, President.25099 2576-68 Institut Philippe Pinel de Montréal Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on June 19, 1968, approved by-law numbers 1, 2, 3 ami 4 of \"Institut Philippe Pinel de Montréal\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.25099 2576-78 Proclamations Proclamations HUGUES LAPOLNTE Canada, Province de Québec.[L.S.J ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, '.leine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.HUGUES LAPOINTE Canada, Province of Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada, and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting. 3502 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1908, 100' aimée, n° 25 Proclamation Proclamation Le procureur général, ( ATTENDU que le con- J.J.Berth and, j YXTHEREAS the miinici-.1.1.BERTRAND, \\ Bêil municipal «lu Attorney Generals pal Council of the canton de Granby, comté de Shefford.a soumis, pour approbation, son règlement numéro 223 à l'effet île soumettre le territoire de celte municipalité à la juridiction de la Cour municipale de la cité de Granby; Attendu que le conseil municipal de la cité de Granby, par son règlement numéro 039 a concouru dans la teneur dudit règlement adopté par le conseil municipil du canton de (iranby; Attendu «|ue, sous l'autorité de l'article 7 «le la Loi des cours municipales (Statuts refondus, 1904, chapitre 24), le lieutenant-gouverneur en conseil a donné son approbation à ces règlements.A ces causes, de l'avis et du consentement «le Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 15S3.en date du 24 mai 1968, et vu les dispositions des articles 693 à 097 de la \\a>\\ des .ités cl villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), et îles articles 3 à 7 «le la Loi des cours municipales (Statuts refondus, 1904, chapitre 24), Nous avons décrété et décrétons qu'à compter de trente et un jours après la publication de la présente proclamation dans la Gazette officielle île Québec, le territoire de la municipalité du canton de Granby sera soumis à la juridiction de la Cour municipale de la cité de (iranby.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icclles appiscr le grand sceau dc Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honora-rable Hugues Lapointe, c.p., ch.lieutenant-gouverneur ce.«le Notre province dc Quéliec.ce dixième jour «le juin en l'année mil neuf cent soixante-huit de 1ère chrétienne et de Notre Règne la dix-septième aimée.Pa ordre, 25015-o Le sous-secrêtaire de la prorince, Raymond Douvii.i.i:.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et dc ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, Salut.Proclamation Le procureur général, ( A TTENDU que, le 30 J.1.Bertrand.\\ avril 1958, par arrè- ' té en conseil numéro 410, la Cour de comté dc Labelle.à Labelle, a été abolie, ù compter du 15 mai 1958; Attendu que, le 11 septembre 1958, par arrêté en conseil numéro 922, ladite Cour de comté dc Labelle a été rétablie et monsieur Georges Godard nommé greffier de cette Cour; v township of Granby, county of Shclford, submitted for approval, its by-law number 223 to the effect of submitting the territory of this municipality to the jurisdiction of the municipal Court of the City of Granby; Whereas the municipal Council of the City of Granby, by its by-law number 639 has agreed to the terms of the said by-law adopted by the municipal Council «>f the township of Granby; Whereas under the authority of section 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statute-, 1964, chapter 24), the Lieutenant-Governor iu Council has given his approval to these by-laws Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a dec rec bearing number 1583, dated May 24, 196S.and in view of the provisions of sections 093 to 697 of the Cities and Towns Act (Revised Statutes.1964, chapter 193).and sections 3 to 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statute-.1964.chapter 24), We have decreed and decree that from ami after thirty-one days Following the publication of the present proclamation iu the Quebec Official Gazette, the territory of the municipility of the township of Granby will be submitted to the jurisdiction of the Municipal Court of the City of Granby.Of all of which Our loving subjects and all others whom these presents may concern an hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In TESTIMONY whereof, Wc liavo caused these Our present letters to l>c made patent, and tlie Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.c.q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Qm'diec, in Our Province of Québec this tenth day of June, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-eighl and in the seventeenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 25015 Assistant Secretary of the Province.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.J ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the faith-To all to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation J.1.Bertrand,/ V\\7HEREAS on April 30.Attorney General.} 1968, by Order in ' Council number 410.thé Court of the county of Lal>clle, at Lalielle, was abolished, from and after May 15.1958; Whereas on September 11, 1958, by Order in Council number 922, the said Court of the county of Labelle was re-established and Mr.Georges Godard appointed clerk of this Court; QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.June 22.19GS, Vol.100.No.25 Attendu que monsieur Georges Godard a démissionné de ce poste comme grellier et qu'il c-l impossible de lui trouver un remplaçant; Attendu que le Conseil municipal de Labelle ne s'oppose pas à l'abolition de ladite Cour; Attendu que ladite (dur, qui s'appelle maintenant Cour Provinciale, siégeant à Labelle, n'a plus sa raison d'être vu le peu d'activités judiciaires qu'elle connaît; Attendu qu'en vertu de l'article 139 de la Loi dea tribunaux judiciaires, tel qu'amendé par l'article 28 de la Loi 13-14 Elizabeth IL chapitre 17.amendant la Loi des tribunaux judiciaires.N - Cours de Magistrat établies et les dossiers, registres, documents et archives des Cours de Magistrat abolies deviennent des dossiers, registres, documents et archives de la Cour Provinciale; Attendu qu'il y a lieu d'abolir la Cour de Magistrat de comté, siégeant à Labelle.\\ ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 1593, en date du 27 mai 1908, Vois avons décrété et ordonné el.par les présentes, décrétons et ordonnons cpie l'arrêté en conseil numéro 922 du 11 septembre 1958 soit révoqué; que la Cour Provinciale ne siège plus à Labelle, district judiciaire de Lahcllc, à compter du 1er mai 196S; que tous les dossiers, registres, documents et archives de celle Cour soient transmis immédiatement au greffe de lu Cour Provinciale de Mont Laurier, chef-lieu du district judiciaire de Labelle; et que le poste «le grellier de la Cour «le Labelle soit alioli.De tout ce que dessus, tous Xos f«:aux sujets ci tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence i a un de quoi, Noua avons fait rendre Nos présentes lettres pateides et sur icellcs apposer h- grand sceau de Xotre province de Québec; TkMOIN: Notre très fhlèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, cp., ch.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville «le Québec, de Notre province «le Québec, Ce quatrième jour «le juin en l'année mil neuf cent soixante-huit de l'ère chrétienne el de Notre Règne la dix-septième nnnée.Par ordre, Le sous-secrêtaire de la province, 25015-O Raymond Douville.Whereas Mr.Georges Godard resigned from this post as clerk and that it is impossible to find someone to replace him: Whereas the Municipal Council of Labelle does not oppose the abolishment of the said Court; Whereas the said Court, which is now called the Provincial Court, sitting at Labelle, has no longer a reason to exist seeing the few judicial activities it acknowledges; Whereas pursuant to section 139 of the Courts of Justice Act, such as amended by section 28 of Act 13-14 Elizabeth II, chapter 17, amending the Courts of Justice Act, the established Magistrate's Courts, the files, registers, documents and archives of the abolished Magistrate's Courts become the files, registers, documents and archives of the Provincial Court; Whereas it is expedient to abolish the Magistrate's Court of the county sitting at Labelle.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1593, dated May 27, 1968, We have decreed and ordered and, hereby, decree and order that Order in Council number 922 of September 11, 1958, be revoked; that the Provincial Court sit no longer at Labelle, judicial district of Labelle.from and after May 1, 1968; that all the files, registers, document - and archives of this Court be transmitted immediately to the ollice of the Provincial Court of Mont-Laurier, head ollice of the judicial district of Labelle; ami that the [Hist of the clerk of the Court of Labelle be aliolishcd.Ok all which Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.o., q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fourth day of June in the year of Our Lord one thousand nine hundred and sixty-eight and in the seventeenth year of Our Reign.By command, Raymond Douville, 25015 Assistant Secretary of the Province.Soumissions Tenders Les Commissaires d'écoles pour la municipalité dc Saint-François-de-Laval Comté dc Fabre Avis public est |»r les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le ¦soussigné Lucien Cartier, secrétaire-trésorier, 6990, Blvd.«les Mille-Iles, (St-François), ville de I a \\.11.P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 9 juillet 1968, pour l'achat de $175,000 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité «le St-Fraiiçois-de-Laval, comté de Fabre, datées du 1er août 1968 et remboursables The School Commissioners for the Municipality of Saint-François-de-Laval County of Fabre Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\", will be received by the undersigned, Lucien Cartier, secretary-treasurer, 6990 des Mille-Iles Blvd.(St-François), town of Laval, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Tuesday, July 9, 1968, for the purchase of an issue of $175,000 of bonds for the school commissioners for the municipality of Saint-François-de-Laval, county of Fabre, dated August 1, 1968 and redeemable serially 3501 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1908, 100' année, n° 25 par séries %.nor more than 7'j','.payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may Ik- the same for the whole issue: however a different rate of interest could, in addition to the initial rate of interest, be accepted iu the case of bonds issued as 10-ycar or 15-year short-term bonds, or 20-year fixed-term bonds, provided however that the amounts thus issued at this different rate, be for wdiole mal inities, bearing iu mind the maturity tables appearing in the present notice.By-laws Nos: 911 - $30.000 \u2014 aqueduct, sewers; 916 \u2014 $22.500 \u2014 aqueduct, sewers; 925 \u2014 $23.000 \u2014 roads; 926 \u2014 $182.000 \u2014 buildings and lands; 927 \u2014 S14.000 \u2014 surveying works; 929 \u2014¦ $20,000 \u2014¦ aqueduct, sewers; 930 \u2014 $20.000 - Park works; 933 \u2014 812.800 \u2014 roads; 936 \u2014 $20.000 \u2014 park works; 937 \u2014 834.000 - emlicllishmcnt works; 940 \u2014 816,700 \u2014 aqueduct, sewers; 941 \u2014 890.500 \u2014 Lighting; 942 \u2014 $80,000 \u2014 expropriation of lots; 946 \u2014 $4,000 - roads; 950 \u2014 $24,000 \u2014 various works; 952 \u2014 $75,000 \u2014 aqueduct, sewers; 956 \u2014 $02,000 \u2014 recreational and community services; 961 \u2014 $29,500 \u2014¦ buildings and lands; 903 \u2014 $13.000 \u2014 aqueduct, sewers; 969 \u2014 $6.000 \u2014 buildings and lands.For adjudication only, interest sliall be calculated as from August 1, 1908. 3506 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 jui» 1908, 100' année, n\" 25 Tableau d'amortissement \u2014 9785,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er août 1969.$34,000 1er août 1970 .36,000 1er août 1971.39,000 1er août 1972 .42,000 1er août 1973 .45,000 1er août 1974 .42,000 1er août 1975 .46,000 1er août 1976.50,000 1er août 1977.53,000 1er août 1978 .57,000 1er août 1979 .26,000 1er août 1980 .27,000 1er août 1981.29,000 1er août 1982 .30,000 1er août 1983 .34,000 1er août 1984 .35,000 1er août 1985 .38,000 1er août 1986.40,000 1er août 1987.44,000 1er août 19S8.38,000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Egalement, des soumissions seront reçues et considérées |>our des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans pourvu toutefois que cet le dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $38,000, et si supérieur à ce dernier moulant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amorl isseinenls annuel-, oui iers, en tenant coin pie du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et cn commençant par les dernières années d'échéances.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas dc l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Longucuil.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque ù Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou cn séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $38,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $38,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er août de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 10 juillet 1968, à 8 heures du soir, Hôtel de Ville, 100 ouest, rue St-Charlcs, Longucuil, comté dc Chambly, P.Q.Table of redemption \u2014 8785,000 \u2014 20 years Vear Capital August 1.1969.$34.000 August 1.1970.36400 August 1, 1971.39.000 August 1.1972.42.000 August 1, 1973 .45.000 August 1.1974.42.000 August 1.1975.40.0011 August 1.1970.50.0(10 August 1.1977 .68,000 August 1.1978 .57,000 August 1.1979 .26.000 August 1.1980 .27.00(1 August 1.1981.29,000 August 1.1982 .30.000 August 1.1983.34.000 August 1, 1984 .35.000 August 1.1985 .38.000 August 1.1980 .40.000 August 1.1987.44.000 August 1, 1988 .38,000 Moreover, lenders may lie sent and shall he considered as 10-year short-term or 15-yenr short-term bonds serially, also tenders shall be received and considered as 10-year short-levin bonds for one part, and the other part as 20-year fixed-term bonds, provided however, that I lib latter pari he for an amount not less than vMM m i and if higher i ban this latter amount, this pirt should include one or more complète annual amortizations, taking into account the maturity tables appearing in the present notice, starting by the last years of maturities.However, tenders shall Ik' sent iu rcsjxTt to only one of Ihe modes of issue hereinabove and they shall be considered for one of the terms only, save in Ihe case of the exception stipulated therein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, pr ncipal and accrued interest il any.by certified cheque, payable at par at Longucuil.Capital and interest are payable at all branches in the province of Québec of the bank whose name is mentioned iu the loan procedure, as well as at the principal ollice of the said bank ID Toronto, Ontario.The said bonds sliall not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-year fixed-term, for an amount equal to $38.000.\" However, if they are issued in part as 20-year fixed-term for an amount higher than $38.000.the bonds so issued sliall lie redeemable by anticipation, at par.on August 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in the present notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will lie opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday.July 10.1968.at 8:00 o'clock p.m.at the Citt Hall, 100 St.Charles Street, West, Longiu nil, county of dumbly, P.Q. QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, June 22.1968, Vol.100, No.25 3507 Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Longucuil, (Comté dc Chambly), ce 13 juin 1908.Le greffier, Réal Bélanger.Hôtel de Ville, 100 ouest, rue St-Charles, Longucuil, (Chamblv), P.Q.Téléphone: 674-4911, code 514.25050-u La Commission des écoles catholiques dc St-Laurent Comté de St-Laurcnt Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumis-sinus pour obligations » seront reçues par le soussigné Louis-L.Deguirc, secrétaire-trésorier, bureau dc la Commission Scolaire, 1100, Côte Vertu, St-Laurent, comté île St-Laurent, jusqu'à 3 heures dc l'après-midi, lundi, le 8 juillet 1968, pour rachat de SI,407,000 d'obligations de la Commission des écoles catholiques de St-Laurcnt, » ¦ -ii i té île St-Laurent, datées du 1er août 1908 et rcmlioursahles par séries 1er août 1909 au 1er août 1988 inclusivement, avec intérêt à un taux mm inféreur à ni supérieur à 7' .payable semi-nnnuellemcnt les 1er août et 1er février dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission, cependant un taux d'intérêt différent pourra en plus du taux d'intérêt initial, être accepté dans le cas des obligations émises à courte échéance 10 ans ou 15 ans, ou terme fixe 20 ans, pourvu que les montants ainsi émis, à ce taux différent soient pour des échéances entières, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Résolutions datées des: 23 mai 1967 \u2014 S4S3.000 construction d'une école élémentaire de 13 classes et dc 2 maternelles; 29 mai 1967 ¦\u2014 $¦'199,500 ¦\u2014 construction d'une école élémentaire; 1(1 octobre 1967 \u2014 $308,000 \u2014 construction d'un édifice à bureaux pour fins administratives; 12 septembre 1967 \u2014 $216,500 \u2014 dépenses d'immobilisation.l'our adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er août 1968.Tableau d'amortissement \u2014 $1,407,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er août 1969.x $86.500 1er août 1970.x 93,500 1er août 1971.x 100,000 1er août 1972.x 106,000 1er août 1973.x 113,500 1er août 1974.x 122,000 1er août 1975 .34,500 1er août 1976 .36,500 1er août 1977.40,000 1er août 1978.42,500 1er août 1979 .45,500 1er août 1980 .49,000 1er août 1981.52,000 1er août 1982 .56,000 1er août 1983 .59,500 1er août 1984 .65,000 1er août 1985.69,000 1er août 1986.73,000 1er août 1987.78,500 1er août 1988.84,500 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuel- d'une somme totale de $582,000 octroyée par le gouvernement provincial The couneil docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Longucuil.(County of Chambly), .lune 13, 1908.Real Bélanger, City Clerk.City Hall.100 Si.Charles Street.West.Longucuil.(Chamblv).P.Q.Telephone: 074-4911.code 514.25050 The Catholic School Commission of St-Laurcnt County of St-Laurcnt Public notice is hereby given that sealed tenders, endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned I.ouis-L.Dcguire, secretary-treasurer, school commission ollice, 1100 Côte Vertu, St-Laurcnt, county of St-I.aurcut, until 3:00 o'clock p.m., Monday, July 8, 190S.for the purchase of an issue of $1,407,000 of bonds for the Catholic school commission of St-I,aurent, county of St-Laurcnt.dated August I.196S.and redeemable serially from August I.1969 to August 1, 1988 inclusively, with interest at a rate not less I ban 61^%, nor more than .'' ( \u2022 payable .semi-annually on August 1st and February 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however a different rate of interest, may, in addition to the initial rate of interest be accepted in the case of bonds issued as 10-year or 15-year short-term bonds or as 20-year fixed-term bonds, provided that the amounts so issued, at such different rate, be for entire maturities, bearing in mind the table of maturities appearing in this issue.Resolutions dated: May 23, 1967 \u2014 S4S3.000 \u2014 construction of a 13 class elementary school nnd 2 kindergartens; May 29, 1967 \u2014 8399,500 \u2014 construction of an elementary school; October 10, 1967 \u2014 8308,000 \u2014 construction of an ollice building for administrative purposes; September 12, 1967 \u2014¦ 8216,500 \u2014 immobilization expenses.For adjudication only, interest shall be calculated as from August 1, 1968.Table of redemption \u2014 $1,.',07,000 \u2014 20 years Year Capital August 1, 1969.x 880,500 August 1, 1970.x 93,500 August 1, 1971.x 100,000 August 1, 1972.x 106,000 August 1, 1973.x 113,500 August 1, 1974.x 122,000 August 1,1975.34,500 August 1, 1976.36,500 August 1, 1977.40,000 August 1, 1978 .42,500 August 1, 1979.45,500 August 1, 1980 .49,000 August 1,1981.52,000 August 1, 1982 .56,000 August 1, 1983 .59,500 August 1, 1984.65,000 August 1, 1985.69,000 August 1, 1986.73,000 August 1,1987.78,500 August 1, 1988.84,500 The \"x\" indicates the years during which annual payments of a total amount of 8582,000 granted by the Provincial Government and 3508 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 196», 100' année.«° 25 el payable en six versements égaux de 897,000 chacun, île 1900 à 1074 inclusivement, seront reçus et appliqués au service de cet emprunt.De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération |xwr des obligations en séries ù courte échanee 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Egalement, des soumissions seront reçues et considérées |x>ur îles obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.pmrvii toutefois que celte dernière partie ne soit, pas jxiur un montant inférieur à SS4.500, et si supérieur à ce dernier montant, celle parÛe devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Cependant) les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut, et ne devront comporter qu'un seul des ternies sauf dans le cas de l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Laurent.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au burnu principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries cl terme lixe 20 ans, pour un moulant égal à $84.500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $84.500.les obligations ainsi émises seront rachetables pir anticipilion.au par, les 1er août de chaque année pour le montant annuel requis p>ur les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à V\", du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue, lundi, le S juillet 1968, à 3 heures de l'après-midi, liurcati de la Commission scolaire, 1100, (Vite Vertu.St-Laurcnt, comté de St-Laurcnt.P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Laurent, (Comté de St-Laurent), ce 13 juin 1968.Le secrétaire-trésorier, Louis-L.Dequiku.Bureau dc la Commission scolaire, 1100, Côte Vertu, St-Laurent (St-Laurent), P.Q., Téléphone: 748-6991, code 514.25092-O Mlle de Cliûleauguay Comté dc Chatcauguay Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions ]x>ur obligations» seront reçues par le soussigné M.Claude Hurtuhise, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 5, Rue de la Station, Chatcauguay, comté dc Chatcauguay, P.Q., payable in six equal instalments of $07,000 each, from 1969 to 1974 inclusively, will be received and applied to the service of this loan.Moreover, tenders may be sent and shall he considered as 10-ycar or 15-year short-term serial bonds.Also, tenders sliall be received and considered as 10-year serial bonds with the balance being partly 10-ycar short-term anil partly 20-year fixed-term, provided however that this hitter part be not for less than $84,500 and if.higher than this latter amount Ibis pari should include only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table ol maturities appearing in this notice, beginning at the last years of maturities.However tenders shall be sent for one only of the above met bods of issue, and shall include only one of the terms, save iu the ease of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, principal and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Laurent.Capital and interest are payable at all bronchi \u2022 in the Province of Québec of the bank whose name is mentioned in the loan procedure, as well as at the principal ollice of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipai ion if they are issued serially or serially and as 20-year lixed-lerni for an amount equal to $84.500.However, if they are issued partly as 20-year lixed-tcrm bonds for an amount higher than $81,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on August.I-I of each year for the annual amount required lo amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by a ccrtilied cheque equal to 1',' of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, July 8, 1968, at 3:00 o'clock p.m., school commission ollice, 1100 Côte Vertu, St-Laurcnt, county of St-Laurent, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St-Laurcnt, (County of St-Laurent), June 13, 1968.Louis-L.Deguiimo, Secrctary-'frcasuri r.School Commission Office, 1100 Côte Vertu, St-Laurent, (St-Laurent), P.Q., Telephone : 748-6991, code 514.25111 -' Town of Ctuîteaugiiay County of Chatcauguay Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will he received by the undersigned, Mr Claude IJurlu-bisc, secretary-treasurer.Town Hall.5 Station street, Chatcauguay, county of Cliateauguav.P.Q., until 8:30 o'clock p.m., Tuesday, July 9, QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3509 jusqu'à 8.30 heures du soir, mardi, le 9 juillet 1908, pour l'achat dc §478,000 d'obligations c accompanied by a certified cheque equal to \\% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds at the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be o|>ened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, July 9.1908.at 8:30 o'clock pirn., at the Town Hall.5 Station street.Chatcauguay, county of Chatcauguay.l'.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Chatcauguay.(Countv of Chftteauguay), June 13, 1908.Claude Hurttbisk.Secretary-Treasurer.Town Hall, 5 Station street.Ch&teauguav (Chftteauguay), P.Q., Telephone: 092-6707, code 514.2Û0XI Town of Rosemfcre County of Terrebonne Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Ph.Gardiner, secretary-treasurer, Town Hall, 186 Philippe St., Rosemère, county of Terrebonne, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., and thereafter until 8:30 o'clock p.m., St-Joseph School, 334 Académie St., Rosemère, county of Terrebonne, P.Q, Monday, July 8, 1968, for the purchase of an issue of $500,000 of Ixmds for the town of Rosemère, county of Terrebonne, dated August 1, 1968, and redeemable serially from August 1, 1969 to August 1, 1988 inclusively, with interest at a rate not less than 6J^%, nor more than 7Vt%< payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, a different rate of interest may, in addition to the QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3511 pourra, cn plus du taux d'intérêt initial, être accepté dans le cas des obligations émises à courte échéance 10 ans ou 15 ans.ou terme fixe 20 ans, pourvu que les montants ainsi émis, à ce taux différent, soient |M)ur des échéances entières, en tenant compte des tableaux d'échéances appa-rab-ant dans le présent avis.Règlement numéro T-182 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduc, égouts.Pour l'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er août 1968.Tableau d'amortissement $500,000 \u2014 20 ans Au ufe Capital 1er août 1909.S 5.000 1er août 1970 .6.000 1er août 1971.0.000 1er août 1972 .6,000 1er août 1973 .7.000 1er août 1974 .7,000 1er août 1975 .8.000 1er août 1976 .8.900 1er août 1977.9.900 1er août 1978.10.000 1er août 1979.10.000 1er août 1980.11.000 1er août 1981 .12.000 1er août 1982.1.3.900 1er août 1983.14.000 1er août 1984.15.000 1er août 1985.10.000 1er août 1986.17.000 1er août 1987.18.000 1er août 1988 .302.000 De plus.îles soumissions pourront être envoyées et elles seront prises cn considération pour îles obligations cn séries à courte échéance 10 ans ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées |K)ur des obligations en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.|>ourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $38.000, et si supérieur ù ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un »u des amortissements annuels entiers, cn tenant Compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront cuiii|Kirter qu'un seul des termes sauf dans le cas de l'exception notée.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er août 1988 au montant de $302.000 comprend un solde de $283.000 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er août 1989.$20.000 1er août 1990 .22.000 1er août 1991.23.000 1er août 1992.25,000 1er août 1993 .27,000 1er août 1994 .29,000 1er août 1995.31.000 1er août 1996 .33.000 1er août 1997 .35,000 1er août 1998 .38,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair a Rosemère.initial rate of interest, be accepted in the case of bonds issued as ten-year short-term or fifteen-year short-term, or as twenty-year fixed-term bonds, provided, that the amounts so issued, at such different rate, be for entire maturities, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice.By-law number T-182 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduct, sewers.For adjudication only, interest shall be calculated as from August 1, 1968.Table of redemption \u2014 $500,000 \u2014 20 years Year Capital August 1, 1969.$ 5,000 August 1, 1970 .6,000 August 1, 1971.6,000 August 1,1972.6,000 August 1,1973 .7,000 August 1, 1974 .7,000 August 1, 1975.8,000 August 1, 1976.8,000 August 1, 1977.9,000 August 1, 1978.10,000 August 1,1979.10,000 August 1, 1980.11,000 August 1,1981.12,000 August 1, 1982.13,000 August 1, 1983.14,000 August 1, 1984.15,000 August 1, 1985.16,000 August 1,1986.17,000 August 1,1987.18,000 August 1, 1988 .302,000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for ten-year short-term or fifteen-year short-term serial lionds.Also, tenders shall be received and considered for ten-year serial bonds, with the balance being partly ten-year short-term and partly twenty-year fixed-term bonds, provided, however, tliat this latter part be for an amount not less than $38,000, and, if higher than this latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall include only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The August 1, 1988 maturity, in the amount of $302,000, comprises a balance of $283,000, renewable for an additional ten-year period, and maturing as follows: Vear Capital August 1, 1989.$20,000 August 1, 1990 .22,000 August 1,1991.23,000 August 1, 1992.25,000 August 1, 1993 .27,000 August 1, 1994 .29,000 August 1, 1995 .31,000 August 1, 1996 .33,000 August 1, 1997 .35,000 August 1, 1998.38,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Rosemère. 3512 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n\" 25 Le capital et les inlérêls sont payables à toutes les succursales our un montant égal ou moindre de $.'1(12.(1110.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme lixe 20 ans pour un montant supérieur à S3O2.00O.les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er août de chaque année pour le montant annuel requis |>our les fins de l'amortissement de rémission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1',,' du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.lies .soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil (pli sera tenue, lundi, le 8 juillet 1008.ù S.30 heures du soir, à l'École St-Joseph.334.rue Académie.Rosemère, comté de Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Itosemère.(Comté de Terrebonne), ce 18 juin 1908.La aeeréiaire-trfsorière, Mme Pu.Gakdiner.Hôtel de Ville.180.rue Philippe, Rosemère.(Terrebonne).P.Q.Téléphone: 025-2440, code 514.25091-o Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head ollice of said bank in Toronto, Ont.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as twenty-year fixed-term bonds, for aii amount equal to or less limn $302,000.However if they are issued partly as twenty-year lived, term for an amount, greater than $302,000, Ihe bonds so issued, will lie redeemable by anticipation, at par, on August 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must Ik- accompanied by a certified cheque equal lo 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the lxmds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, July 8, 1968, at 8:30 o'clock p.m.in St-.Ioseph School, 334 Académie St., Rosemère, county of Terrebonne, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Rosemère, (County of Terrebonne), June IS, 1968.Mrs.Pir.GAitniNi:u.Secretary-Treasurer.Town Hall, 186 Philippe St., Rosemère, (Terrclionnc), P.Q.Telephone: 625-2446, code 514.25091 Ventes par Shérifs Sheriffs' Sales AVIS PUBLIC\", est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.BEDFORD Canada - Province de Québec District de Bedford Cour Supérieure, i TJERMAX GIN'TER.dc- Superior Court, f No 10.235.< 11 mandeur, vs DAME No.16,235.\\ I MARY GLADYS FLEURY et al.défendeurs.1° line ferme située dans le dix-neuvième rang de la municipalité du canton de Bolton, connue et désignée comme étant les lots numéros mil cent soixante, mil cent soixante et un, mil cent soixante et trois et mil cent soixante et quatre (1160-1161-1103-1104) des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton, comté de Brome, contenant cent soixante quatorze (174) acres de terrain cn superficie, plus ou moins; 2° Un morceau de terrain situé dans la même municipalité du canton de Bolton contigu de la propriété ci-dessus décrite, formant quarante-trois (43) acres de terrain en superficie, plus ou moins, connu et désigné comme étant partie des ots numéros mil cent cinquante-huit et mil cent soixante-deux (Pt.1158-1162) sur lesdits plan et livre dc renvoi du canton de Bolton, désigné et borné comme suit: commençant à un poteau sur la ligne sud dudit lot 1102, ledit poteau étant l'extrémité sud de la ligne di\\ isant les propriétés dc Monsieur Rogers et Monsieur M.Boisvert PUBLIC NOTICE is hereby given thai the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respect* ive times and places mentioned below.BEDFORD Canada \u2014 Province of Québec District of Bedford HERMAN GINTER, plaintiff, vs DAME MARY GLADYS FLEURY et al, defendants.1.A farm property situated in the nineteenth range of the township of Bolton, known und designated as being lots number eleven hundred and sixty, eleven hundred and sixty-one, c.cvcn hundred and sixty-three and eleven hundred and sixty-four (1160-1161-1163-1164) on Unofficial cadastral plan of said township of Bolton, Brome county containing one hundred and seventy-four (174) acres of land in superficie-, more -rr less; 2.A piece of land situated in the same township of Ih-lton, adjoining the property hereinabove described, forming forty-three (43) acres of land in superficies, more or less, known and designated as being part of lots numbers eleven hundred and fifty-eight and eleven hundred and sixty-two (Pt.1158-1162) on said plan of the township of Bolton, described and bounded as follows: starting at a post on the south line of lot 1 Hi-said post being the south extremity of the nine dividing Uie properties of Mr.Rogers' and Mr.M.Boisvert's (id est dividing the east half of lot QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, IMfl.Vol.100, So.25 3513 id est divisant la moitié dc Test du lot numéro number four (4) in the ninth range of said town-sant et ARMAND GACîNON, demandeur cn reprise d'instance.l'n terrain situé en la paroisse de St-Narcisse, fai-ant partie du lot de terre connu et désigné sous le numéro deux cent soixante-cinq (Plie 265) aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse île St-Narcisse, mesurant vingt-cinq pieds dc largeur sur une profondeur moyenne de quatre-vingt-seize pieds, le tout à la mesure anglaise, et plus ou moins, quant à la profondeur, de façon ii ce que la ligne de profondeur ne dépaaw pas la ligne de profondeur des terrains voisins situés du côté nord-est; borné comme suit: en front, par le chemin public, ou route conduisant au deuxième rang, en profondeur, vers le sud-est.et d'un ci\")té vers le sud-ouest par le résidu de la terre du bailleur et de l'autre côté vers le nord-est pir le Preneur, avec bAtisscs dessus construites.> Pour être vendu au bureau d'enregist renient de Sic-Geneviève dc Uatiscan.MERCREDI, le VINGT-QUATRIÈME jour du mois de .11 II.-I.l'.r.mil neuf cent soixante-huit, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif intérimaire.llureau du shérif.Yolande Cloutier.Trois-Rivières.le 17 juin 1068.25098-o TROIS\u2014RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Trois-Rivières Superior Court.I A RTHUR MORINVILLE, No.29979.< domiciled at G rand'Mè- t re East, dictriet of St-Maurice, plaintiff, VS JEAN-CHARLES HAMELIN.domiciled at St-Narcisse.district of Trois-Rivières, defendant, the said .1.CHARLES HAMELIN, opinent, and ARMAND GAGNON, plaintiff in continuance of suit.\"A lot of land situated in the parish of St-Narcisse.forming part of the lot of land known and designated under numlier two hundred and sixty-five (P.265).on the official plan and in the book of reference of the parish of St-Narcisse, measuring twenty-five feet in width by an average depth of ninety-six feet, the whole English measure and more or less with respect to the depth, in such a way that the line of the depth does not extend past the line of the depth of the neighboring lands situated on the north-east side, and bounded as follows: in front by the public road or the road leading to the second range, in depth, on the southeast, and on one side, on the southwest, by the remainder of the land l>elonging to the lessor and on the other side, on the north-cast, by the buyer, with the buildings constructed thereon.\" To be sold in the registry oflice of Sic-Geneviève de Uatiscan, on WEDNESDAY, the TWENTY-FOURTH day of the month of JULY, one thousand nine hundred and sixty-eight, at THREE o'clock in the afternoon.Yolande Cloutier, Sheriff's Office, Acting Sheriff.Trois-Rivières.June 17, 1968.2.5098 INDEX I¥o 25 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 1273 \u2014 Conditions des contrats à intervenir entre, d'une part, un architecte membre dc l'Association des architectes dc la province de Québec ou un ingénieur membre de la Corporation des ingénieurs du Québec et un ministre dc la Couronne ou tout organisme, commission ou corporation d'autre part en vue dc retenir les services desdits architecte ou ingénieur.3393 1273 \u2014 Terms of contracts between an architect in private practice who belongs to the Province of Québec Association of Architects, or an engineer in private practice who belongs to the Corporation of Engineers of Québec on one hand, and a minister of the Crown, or any organization, commission or corporation on the other hand, with a view to retaining the services of the said architect or engineer.3393 1399 \u2014Normes du travail dans l'exécution des contrats et sous-contrats de construction du Gouvernement du Québec {Règlements).3451 1399 \u2014 Labour standards to be observed when carrying out Québec Government construction contracts and sub-contracts (Regulations).3451 1636 \u2014 Forêt domaniale gaspésienne et les forêts domaniales de Roberval et du Saguenay.3454 1636 \u2014 Gaspé Crown Forest and the Crown Forests of Roberval nnd Saguenay.3454 1673 \u2014 Division dc la province pour les fins de la chasse.3465 1673 \u2014 Division of the Province for hunting purposes.3465 1674 \u2014 Permis de chasse.3458 1674 \u2014 Hunting Licenses.3458 1675 \u2014 Réserve de Rimouski, (Règlements).3462 1675 \u2014 Rimouski Reserve (Regulations).3462 1676 \u2014 Chasse de la perdrix.3466 1676 \u2014 Hunting of partridges.3466 1677 \u2014 Chasse au caribou.3461 1677 \u2014Hunting of caribou.3461 1678 \u2014 Chasse au chevreuil et A l'orignal (certaines méthodes).3461 1678 \u2014 Hunting methods (Moose and deer).3461 1679\u2014Ours polaire.3461 1679 \u2014Polar bears.3461 3518 GAZETTE OFFICIELLE DE QUÉBEC, 22 juin 1968, 100' année, n\" 25 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Couneil (suite) (continuai) 1680 \u2014 Chasse aux rats musqués.3462 1680 \u2014 Hunting of muskrats.3462 1681 \u2014 Chasse à l'orignal, du chevreuil et du caril>ou (Périodes de chasse).d'il 1681 \u2014 Hunting of moose, deer and caribou (season).3464 1703 \u2014 Construction, Sorel.\u2022\u2022\u2022.3450 1704 \u2014 Employés de garages, Trois-Rivières et Shawinigan.34.11 1704 \u2014 Garage Employees, Trois-Rivières and Shawinigan.3431 1705 \u2014 Construction, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Granby.3369 1705 \u2014 Construction, St.Hyacinthe, Saint-Jean, (iranby.3360 1706 \u2014 Verre, Montréal.3424 1706 \u2014 Glass, Montreal.3424 1708 \u2014 Serrurerie et menuiserie métallique, Montréal.8459 1708 \u2014 Non-structural Metalwork, Montréal .3459 1710 \u2014 Employés de postes de service et débits d'essence, Chicoutimi.8450 1710 \u2014 Service Station and Gasoline Station Employees, Chicoutimi.3450 1711 \u2014 Construction, Montréal.8420 1712 \u2014 Photographes professionnels.Cantons de l'Est.3392 1712 \u2014 Professional Photographers, Eastern Townships.3302 1713 \u2014 Coiffeurs pour dames, Montreal.3 15?1713 \u2014 Hairdressers (Ladies ) Montréal.3167 1714 \u2014 Construction, Montréal.3458 1715 \u2014 Coiffeurs pour dames, Montréal.3460 1715 \u2014 Hairdressers (Ladies') Montreal.3 MO 1716 \u2014 Alimentation, détail, Montréal.8460 1716 \u2014 Food, Retail, Montréal.8460 1729 \u2014 Cimetières d'automobiles et les dépotoirs le long des routes.3156 1729 \u2014 Roadside automobile graveyards ami dumps.8456 1739 \u2014 Soustraction au jalonnement d'une certaine étendue de terrain dans le territoire du Nouveau-Québec (Abrogation d'un règlement).3456 1739 \u2014 Withdrawal from staking a certain strip of land in the territory of New Québec (Abrogation of a regulation).3456 ASSOCIATION Coopérative COOPERATIVE Association Association coopérative cle St-Méthode (Ch.slat.).3493 AVIS Divers MISCELLANEOUS Notices Adelstein.Ronald Joseph (Dcm.-Appl.).346!} Hourlamaquc, villc-town (Requête-Pétition).3176 Cowe, Andrew Buchan (Dein .-A ppl.).8460 Haber.Joanna Amalia (Dem.-Appl.).Lac Lemoyne, munie.(Requête-Pétition).8476 Notre-Damc-du-Iec inc.3330 Edifranee Inc.3331 Entrepôts St-André ltée (Les).3331 Entreprises A.G.P.inc.(Les).3331 Entreprises A.Ricci inc.(Les).3332 Entreprises Léo Guilbcault ltée (Les) 3332 Entreprises Limont inc.3332 Entreprises Pierrekand ltée (Les).3350 Entreprises robustes inc.(Les).3332 Entreprises 407 inc.3333 Etna Holding Ltd.3333 Ferraro inc.3333 Filler inc.3334 Fondation Familiale des Bourses d'Études inc.3334 Fondation Richelieu Montréal (La) .3334 Foyer de Valcourt inc.3335 Garage dc l'Est inc.3336 Garage Tremblay automobiles inc.3336 Garmont Industries Ltd.3339 Gestion SLF limitée.3357 Graphie Estates Limited.3336 Grondin (Jean) inc.3337 Grossiste des Décorateurs du Québec inc.3337 3520 GAZETTE OFFICIELLE DE QUEBEC, 22 juin 19G8, 100' année, n° 25 Lettres patentes Letters Paten t (suite) (continued) Hakimi (D.) Inc.3337 Honeycutt Inc.3338 Hôpital Général de la Région de l'Amiante inc.3338 Huneault (Y.) Television Inc.3338 Iceberg Refrigeration Inc.3338 Imprimerie Vanier inc.3339 Industries Garmont ltée (Les).3339 Investissements Crépin inc.(Les).3325 Jalbert (Nelson) inc.3339 Jenkin (Lee) Realties Inc.3340 Krumholz (Norman) Production Consultants Inc.3340 L.& II.Cleaners Inc.3341 L & C Productions Inc.3352 Lajoie & Hudon automobile ltée.3341 Lamer Building Inc.3342 Langelier (France) inc.3342 Langevin (Roy) liée.**341 Lantliicr & Lalonde Leasing Limited.3342 Lantliicr & Lalonde location limitée.3342 Laprade (R.) & fils inc.3343 Laurentide Outdoor Cinema Inc.3322 Leduc.(A.) et frères limitée.3343 Leisure Lady Originals Inc.3343 Loisirs Duberger inc.(Les).3344 Lower River Glass Inc.3303 Magasin Continental (Shippagan) ltée.3344 Maison du Peuple de Montréal inc.(La) 3344 Maison Maxime (1008) inc.3.144 Maison Rosemère inc.(La).3350 Manoir de Brucy inc.3345 Marine Nor-Sport Laurcnliaii lue.3345 Matériaux Bonhomme (St-Fiislachc) inc.3345 Mazzini Investments Inc.3351 Menuiserie Biais & fils inc.3346 Mesibos Shabbos Day Camp.3346 Moeon Inc.3347 Modal Inc.3347 Morley Associates Inc.3317 Morley associés inc.3347 Mouvement Civique de Saint-Laurent (Le).3347 Osco (Qucliec) Limited.334S Osco (Québec) limitée.3348 Oxford Paper Sales Ltd.3348 Panneton (Marcel) liée.3340 Parizcau (Gérard) ltée (Correction)- 3340 Pekuniar inc.3340 Perron (G.) Auto Côte-Nord limitée (Correction).3349 Photographes associés de Place Bonaventure inc.3310 Pierre Hair Experts (Ottawa) Inc.3350 Pierrekand Enterprises Ltd.3350 Pizzeria (Lorenzo) Inc.3350 Placements Bacdem inc.(Les).3350 Placements Caserta ltée.3319 Placements Marcel Panneton inc.3351 Placements Mazzini inc.(Les).3351 Placements Pointe-Claire ltée.3351 Plaza Cartier limitée.3352 Pointe-Claire Investments Ltd.3351 Poirier (François) limitée.3352 Productions L & C inc.(Les).3352 Productions Risser inc.(Les).3353 Produits chimiques Astro inc.(Les) .3316 U.C.Promotions ltée.3353 Provost (Jean) & Associate Ltd.3353 Provost (Jean) et associés, ltée.3353 E.A.Ranger (E.A.) & fils ltée.3354 Recherches Sous-Marines du Québec inc.3354 Reina Concessions Inc.3354 Rénovation Urbaine de Montréal inc.(La).3355 Restaurant Blouin inc.3355 Restaurant Cosmos Montréal inc.3324 Roberge (J.L.) & fils amusements inc.3355 Robust Enterprises Inc.3332 Rosemère House lue.3300 Ross Converters Ltd.3356 Roy (Georges E.) inc.3350 SLF Holdings Limited.3357 Saibil (Stan) Associates lue.3357 St-Laurent électrique limitée.3357 Sample Blouse & Spirt swear Ltd.3357 Savoie (Paul) inc.335S Scandinavian Craft & Decor Inc.3358 Sept-Iles métal ltée.3358 Services ( 'anaiï ltée (Les).3359 Services St-Lin inc.(Les).335!) Smith (G.) Sales Limited.3359 Sociaad Inc.3360 Société Lyrique d'Aubigny.inc.(La) .3300 Stéréo Laval inc.3300 Sumar Construction Ltd.3301 Tradition House.3361 Trojan Holding Co.Ltd.(The).3361 Union Marking Devices Inc.3362 Universal Auto Tire Y.ST.P.Inc.331.2 Villa Gagnon inc.3363 Vitrerie du Bas du Fleuve inc.3363 VolcO Hunting and Fishing Club Inc.3363 World Wide Associates lue.3361 Wrenbury Holdings Ltd.3364 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Archway Ltd.3304 Campbell Si Cameron Ltd.3301 ( 'entre Mgr Boulfarcl inc.330.\".Charo Farm Ltd.3360 Collège Stc-Marie.3365 Doll Park Ltd.3365 Douglas (Hunter) International Ltd.3305 DuBrow (Leon) Corpiration .336.'.Entreprises de Nettoyage d'Édifices limitée (Les).3365 Ferme Charo ltée.3360 Fermes du ( !ap St-Jacques ltée (Les) .3366 Fournicr (Yvon) limitée.3366 Garant inc.3366 Hellenic Poultry Co.Ltd.3366 Industrie Porcine du Québec limitée., .3367 Magnetics International Ltd.3367 Marché Union inc.330, Ouellet & Labcrge (limitée).3368 Pavillon Emile-Gérard inc.3365 Petites Soeurs de l'Assomption incorporée (Les).3868 Rembourrage Vietoriaville liée.3368 Sandra Children's Wear lue.33618 Simard International inc.3368 Vietoriaville Upholstering Ltd.3368 960 Victoria Square lue.3369 Sieges sociaux Head Offices Ahuntsic Florist (1967) Inc.3400 Allied Handling & Storage Equipment Ltd.3489 Autobus Trans-Québec inc.3491 Benettic Inc.8490 boucherie Papineau liée.3490 Caverne du Disque ltée.3489 Charles Sportswear Inc.3491 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 22, 1968, Vol.100, No.25 3521 Sièges sociaux Head OJJices (suite) (continued) Classic Construction inc.3490 < 'ontrecocur Telephone Ltd.3490 Cosmétiques Rodriguez inc.(I^cs).3491 Design Workshop Ltd.3491 Fleuriste Ahuntsic (1907) inc.3490 Gestion SLF limitée.3492 Instant Sales Corp.3492 Jagg Mines Inc.3492 Mines Jagg inc.(Les).3492 Outillage de Manutention & d'Entreposage ltée.34S9 Pavillon St-Charlcs de Limoilou.3489 Papineau Rutchers Ltd.3490 Periodica Inc.3491 Prospect Shoes Ltd.3489 Record Cave Ltd.(The).3489 SLF Holdings Limited.3492 Téléphone «le Contrecoeur ( Le).3490 Weyrich Chemicals & Co.Ltd .3491 DEMANDE APPLICATION à la Législature to Legislature Oratoire Eglise Baptiste Française (L\").3493 I IOI IDATION WINDING ¦vis de up Notices Compagnie de téléphone local du canton de Wotton (La).3494 Compagnie «le téléphone de Stc-Sophie .le Mégantic (La).3494 Haw Milk Producers Syndicate of the County of Richmond '( U.C.C.).3500 Secrétariat industriel de Beaupré.3494 Syndicat des producteurs de lait nature du comté de Richmond.3500 MINISTÈRES DEPARTMENTS Vflaires municipales Municipal Affairs Bcrnières, munie.(Nom-Naine ch.).3497 Ste-Anne-de-Bellevue (Annex.).3497 Val-Saint-Gilles, munie.(Publ.).3497 I
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.