Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 mai 1969, samedi 17 (no 20)
[" 101e année vol.101 2771 kxette officielle ùu Québec QUEBEC OFFICIAL A Z E T T E Québec, samedi 17 mai 1969 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Quebec, Saturday, May 17,1969 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typograplu'cal error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Official Publisher 2772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° 20 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 30 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 10 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $3 des 100 mots.Exemplaire séparé: 50 cents chacun.Feuilles volantes: $2 la douzaine.Abonnement: $10 par année à compter de janvier.N.B.\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocn Lefebvhe.Hotel du Gouvernement, Québec, 13 mars 1908 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 30 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 10 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $3 per 100 words.Single copies: 50 cents each.Slips: $2 per dozen.Subscriptions: $10 per year from January.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rocii Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, March 13, 1008 27440 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire nu tarif de la troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes Action Photo Service Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour de mars 1969, constituant en corporation: Allan Lcishman, 8757, rue Dubé, LaSalIe, Gilles Corbcil, 151, rue Galt, Verdun, tous deux photographes, et David Kirshenblatt, avocat, 5636, avenue Greenwood, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Entreprendre tous genres de travaux photographiques, sous le nom de « Action Photo Service Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 151, rue Galt, Verdun, district judiciaire de Montréal.Iour les objets suivants: Exploiter une école dc conduite, sous le nom de « École de conduite Métro inc.\u2014 Metro Driving School Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune ct en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est à Longucuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1453-69 Écurie G.L.inc.G.L.Stable Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour de mars 1969, constituant en corporation: Gilles Lachancc, conducteur ct entraîneur, 29, Rang St-Joachim, Saint-Benoit, comté dc Deux-Montagnes, Claude Chamberland, représentant de commerce, 25, Terrasse Paquin, Laval, ct Raymond Lachancc, entraîneur, 275, St-Augustin, Saint-Augustin, comté de Deux-Montagnes, pour les objets suivants: Faire l'importation, l'exportation, l'élevage, le dressage, l'entraînement et en général faire lc commerce dc chevaux de course, sous le nom de « Écurie G.L.inc.\u2014 G.L.Stable Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune ct en 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saintc-Scholastique, district judiciaire dc Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1318-69 2785 Dyne Holdings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Oscar Respitz, 4945 Glencairn, Philip Shugar, 4055 Bourret, both of Montreal, and Sydney B.Sederoff, 80 Crestwood, Montreal West, all three advocates, for the following purposes: .To carry on the business of a real estate, construction and holding company, under the name of \"Dyne Holdings Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183-o 1311-69 École de conduite Métro inc.Metro Driving School Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of April, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adricn-R.Paquctte, advocate, 212 Bloomfield, Outrcmont, Gilbcrte Baron, 5154 Jcanne-Mance, and Gisèle Tourville, 3261 Forest Hill, the two latter secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To operate a driving school, under the name of \"École de conduite Métro inc.\u2014 Metro Driving School Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Longucuil, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1453-69 Écurie G.L.inc.G.L.Stable Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Lachancc, driver and trainer, 29 St-Joachim Range, Saint-Benoit, county of Two-Mountains, Claude Chamberland, business representative, 25 Terrasse Paquin, Laval, and Raymond Lachancc, trainer, 275 St-Augustin, Saint-Augustin, county of Two-Mountains, for the following purposes: To import, export, breed, break in, train, and, in general, to deal in race horses, under the name of \"Écurie G.L.inc.\u2014 G.L.Stable Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saintc-Scholast iqiic, judicial district of Terrebonne.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1318-69 2780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° SO Eden Holdings Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la premiere partie dc la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour dc mars 1969, constituant en corporation: Rodrigue Plante, administrateur, 440, Sherbrooke est, upp.1411, Montréal, Denise Plante, ménagère, épouse séparée de biens de Germain Dupont, Saint-Gabriel-de-Brandon, ct Lyse Guimond, secrétaire, fille majeure, 1054, Dollard, app.3, Longucuil, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie tic portefeuille (holding), sous lc nom dc « Edcn Holdings Ltd.», avec un capital total île 8100,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de S10 chacune ct en 700 actions privilégiées dc $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 440, rue Sherbrooke est, app.1411, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-o 1158-69 Les Éditions Algonquin inc.Algonquin Publishing Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province u accordé des lettres patentes, en date du 28c jour dc mars 1969, constituant en corporation: James Khazzam, 44, Sunny.lise, Wcstmount, Guy Taillcfcr, 10152, Christophe-Colomb, tous deux avocats, et Suzanne Pelletier, professeur, fille majeure, 12041, Pasteur, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, libraires et relieurs, sous lc nom de « Les Editions Algonquin inc.\u2014 Algonquin Publishing Inc.», avec un capital total de $150,000, divisé en 1,500 actions ordinaires dc $10 chacune ct eu 1,350 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1423-69 Les Entreprises Fero Itri-Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, l'administrateur du gouvernement dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de mars 1969, constituant en corporation: Femand Buteau, administrateur, Madame Fernand Buteau, ménagère, épouse dudit Fernand Buteau, tous deux dc 660, Richelieu, Québec, ct Lucien Cou-turc, administrateur, 1329, Duquct, Sillery, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc transport, sous lc nom de «Les Entreprises Fero ltée», avec un capital total dc $40,000, divisé en 100 actions ordinaires dc $100 chacune ct en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1003-69 Edcn Holdings Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rodrigue Plante, administrator, 440 Sherbrooke cast, Apt.1411, Montreal, Denise Plante, housewife, wife separate as to property of Germain Dupont, Saint-Gabricl-de-Brandoii, and Lysc Guimond, secretary, spinster of the full age of majority, 1054 Dollard, Apt.3, Longucuil, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Edcn Holdings Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 700 preferred shares of $100 each.The head olficc of the company is at 440 Sherbrooke St.East, Apt.1411, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1158-69 Les Éditions Algonquin inc.Algonquin Publishing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: James Kha/.zsini, 44 Sunnysidc, Wcstmount, Guy Taillefcr, 10152 Christophe-Colomb, both advocates, and Suzanne Pelletier, professor, spinster of the full age of majority, 12041 Pasteur, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as publishers, printers, booksellers and book-binders, under the numc of \"Les Éditions Algonquin inc.\u2014 Algonquin Publishing Inc.\", with a total capital stock of $150,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 1,350 preferred shares of $1(X) each.The head ollicc of the compnny is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1423-69 Les Kni i-i-pri.-cs Fero ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of March, 1969, have been issued by the Government Administrator of the Province, incorporating: Fernand Butcau, administrator, Mrs.Fernand Butcau, housewife, wife of the said Fernand Buteau, both of 660 Richelieu, Québec, and Lucien Couture, administrator, 1329 Duquet, Sillcry, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Les Entreprises Fero ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1003-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO Les Entreprises Gay-Net inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour d'avril 1969, constituant en corporation: André Gauthier, avocat, 1990, des Ormes, Saint-Bruno-de-Montarville, Ginette Tardif, 3980, Pierre Chevrier, et Lise Marsolais, 2577, Arçand, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Pourvoir à l'entretien d'édifices et/ou de locaux de toute nature comprenant, et non restrictivement, bureaux, ateliers et résidences, sous le nom dc « Les Entreprises Gay-Net inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $1 chacune ct en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Lc siège social de la compagnie est 6438, rue Migncault, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-mitiislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1386-69 Les Entreprises Gerle inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour d'avril 1969, constituant en corporation: Jean Germain, ingénieur, 3475, Beauséjour, Michel Leboeuf, administrateur, 3445, Ridgewood, tous deux dc Montréal, ct Guy Blanchette, avocat, 305, Continental, Sherbrooke, pour les objets suivants: Manufacturer ct faire lc commerce de liqueurs douces, eaux gazeuses et eaux minérales, sous lc nom de « Les Entreprises Gerle inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 400 actions ordinaires dc 8100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 374, Wellington sud, Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1380-69 Entreprises Reno inc.Reno Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de mars 1969, constituant en corjioration : James Khazzam, 44, avenue Sunnysidc, Wcstmount, Guy Taille-fer, 10152, Christophe-Colomb, tous deux avocats, ct Suzanne Pelletier, professeur, fille majeure, 12041, rue Pasteur, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous articles pouvant servir à la décoration, au rajeunissement, à la rénovation, à l'amélioration ou à l'embellissement d'immeubles en général, sous le nom de « Entreprises Reno inc.\u2014 Reno Enterprises Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1422-69 2787 Les Entreprises Gay-Net inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of April, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Gauthier, advocate, 1990 des Ormes, Saint-Bruno-dc-Montarville, Ginette Tardif, 3980 Pierre Chevrier, and Lise Marsolais, 2577 Arcand, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To sec to the maintenance of buildings and/or locals of any nature including, not rcstrictively, offices, workshops and residences, under the name of \"Les Entreprises Gay-Net inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 6438 Migncault Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1386-69 Les Entreprises Gerle inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of April, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean Germain, engineer, 3475 Beauséjour, Michel Leboeuf, administrator, 3445 Ridgewood, both of Montreal, and Guy Blanchette, advocate, 305 Continental, Sherbrooke, for the following purposes: To manufacture and deal in softdrinks, aerated water and mineral water, under the name of \"Les Entreprises Gerle inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 374 Wellington south, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1380-69 Entreprises Reno inc.Reno Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: James Khazzam, 44 Sunnyside Avenue, Westmount, Guy Taillefer, 10152 Christophe-Colomb, both advocates, and Suzanne Pelletier, professor, spinster of the full age of majority, 12041 Pasteur Street, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all articles used in the decorating, renovation, renewal, improvement or embellishing of immovables in general, under the name of \"Entreprises Reno inc.\u2014 Reno Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1422-69 2788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n\" 20 Les Entreprises Vimont inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, lc lieutenant-gouverneur île la province a accordé des lettres patentes, en dutc du lie jour d'avril 1960, constituant en corporation: Georges Malcnfant, entrepreneur, 1829, Delorme, Laval, Claudette Martel, secrétaire, fille majeure, 648, 12e avenue, ct Jacques I.amoureux, avocat, 343, 41e avenue, ces deux derniers de Lachinc, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction ct faire lc commerce dc toutes sortes de matériaux, sous lc nom de « Les Entreprises Vimont inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 1829, Delorme, Laval, district judiciaire dc Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlULlPPE Bouchard.29183-0 1289-69 Les Entreprises Vimont inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Uth day of April, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Georges Malcnfant, contractor, 1829 Delorme, Laval, Claudette Martel, secretary, spinster of the full age of majority, 648, 12th Avenue, and Jacques 1,amoureux, advocate, 343, 41st Avenue, the latter two of Lachinc, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors and to deal in all kinds of material, under the name of \"Les Entreprises Vimont inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 1829 Dclormc, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1289-09 Fil Drywall & Painting Inc.Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie dc lu Loi des compagnies, lc licutenunt-gouverneur dc lu province a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour dc mars 1969, constituant en corporation: Maurice J.Boxer, 1411, Carol Crescent, Laval, Leslie I.Notkin, 3742, Lc Boulevard, Wcstmount, tous deux avocats, ct Laura Boxer, secrétaire, épouse sé-]>arée dc biens «le Fred Firestone, 10250, Bois de Boulogne, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce dc constructeurs ct d'entrepreneurs sous lc nom de « Fil Drywall & Painting Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 1,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 4613, place Neuilly, Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183 920-69 Fil Drywall & Painting Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice J.Boxer, 1411 Carol Crescent, Laval, Leslie I.Notkin, 3742 The Boulevard, Wcstmount, both advocates, ami Laura Boxer, secretary, wife separate as to property of Fred Firestone, 10250 Bois de Boulogne, Montreal, for the following purposes: To conduct and carry on the business of builders and contractors, under the name of \"Fil Drywall & Painting Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 4613 Place Neuilly, Saint-Léonard, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183-0 920-09 Armand Gagnon transport ltc*e Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour dc mars 1969, constituant en erporation: Louis Rémillard, 1169, Brown, Québec, Paul Vézina, 7040, Place Montclair, Charlesbourg, tous deux avocats, et Susanc Bcaulac, secrétaire, fille majeure, 3072, chemin des Quatre-Bourgcois, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc transport, sous le nom dc « Armand Gagnon transport ltée », avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est i\\ Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1361-69 Armand Gagnon transport ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of March, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Kém il Ian I, 1169 Brown, Québec, Paul Vézina, 7040 Place Montclair, Charlesbourg, both advocates, and Susanc Bcaulac, secretary, spinster of the full age of majority, 3072 des Quatre-Bourgeois Road, Saintc-Foy, for the following purposes: To carry on .business as a transport company, under the name of \"Armand Gagnon transport ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Quebec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29183 1361-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO (.iron Hydro-Électrique Cie ltée Giron Hydro-Electric Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première purtic dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour d'avril 1969, constituant en corporation: Jean-Marie Giron, teclini-cien, 11820, Alfred, Montréal-Nord, Laurent Dubé, mécanicien, 7770, St-André, ct Claude Gagnon, commerçant, 708, Jarry est, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce dc machines, moteurs, outils, instruments et quincaillerie dc toutes sortes, sous lc nom dc « Giron Hydro-Électrique Cie ltée \u2014 Giron Hydro-Electric Co.Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 11820, rue Alfred, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêralices, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 1546-69 G.M.F.& associés inc.G.M.F.& Associates Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour d'avril 1969, constituant en corporation: Louis-Claude Trudel, 237, Bloomfield, Outremont, Gaston Gamachc, 2921.Quévillon, Gaston Nndeau, 8105, Jean-Nicolet, tous deux dc Montréal, Yves Bertrand, 190, Poitou, ct Mario Létourncau, 522, Lartigue, ces deux derniers de Laval, tous cinq avocats, pom- les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement, sous lc nom de « G.M.F.& associés inc.\u2014 G.M.F.& Associates Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires dc $1 chacune ct en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183-0 185-69 Les Granits de Québec (1969) inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de mars 1969, constituant en corporation: Marcel Painchaud, entrepreneur, 150, de la Falaise, Bcauport, Paul-André Morin, conseiller en construction, 257, Darveau, Duberger, et Rosaire LeBlanc, technicien, 162, Mistral, Villeneuve, pour les objets suivants: Posséder ct exploiter des carrières, sous le nom dc « Les Granits de Québec (1969) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $10 chacune et en 360 actions privilégiées dc $100 chacune.l.i- siège social de la compagnie est 162, rue Mistral, Villeneuve, district judiciaire de Québec./.t No.1775 containing 209300 sq.ft.Lot No.1791 containing 88900 sq.ft.Lot No.1792 containing 104300 sq.ft.with buildings there on erected.Municipal taxes: 866.20; school taxes: 8204.75.Total: 8270.95.As belonging to Mrs Aidée Bourgeois three lots of land known on the same cadastre as follows: Lot No.1106 containing 166800 sq.ft.Lot No.1161 containing 80030 sq.ft.with buildings there on erected; Mrs Aidée Bourgeois QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2817 & Jimmy Thome, lot No 1157 contenant 102400 pd.c.Taxes municipales: $19.28; taxes scolaires: $74.35.Total: $93.63.Comme appartenant à Jimmy Thorne, deux lots dc terrain connus au même cadastre comme suit: Lot No 1105 contenant 106800 pd.c.Lot No 1162 contenant 80030 pd.c.Taxes municipales: $4.16; taxes scolaires: $9.69.Total: $13.85.Comme appartenant à Maurice W.Bouchard un lot de terrain connu au même cadastre comme suit: Lot No 2379 contenant 130700 pd.c.Taxes municipales: $4.13; taxes scolaires: $9.93.Total: $14.00.Comme appartenant à Isaac C.Bourgeois un lot dc terrain connu au même cadastre comme suit: Lot No 2335 contenant 201360 pd.c.Taxes municipales: $15.01; taxes scolaires: $38.87.Total: $54.48.Comme appartenant ù Raymond H.Lapicrrc un lot dc terrain connu au même cadastre comme suit : Lot No 1251 contenant 81100 pd.c.Tuxcs municipales: $48.88; taxes scolaires: $0.98.Total: $49.86.Comme appartenant ù Jeffrey Turbidc & Alias un lot de terrain connu au même cadastre comme suit: Lot No 2352 contenant 217800 pd.c.Taxes municipales: $2.43; taxes scolaires: $10.86.Total: $13.29.< 'online appartenant ù Éric J.Bourgeois, un lot dc terrain connu au même cadastre comme suit : Lot No 2386 contenant 456200 pd.c.Taxes scolaires: $16.42.Total: S16.42.Comme appartenant ù Léo-Paul E.Lapicrre un lot dc terrain connu au même cadastre comme suit: Lot No 1551 contenant 40300 pd.c.Taxes municipales: $9.77; taxes scolaires: $33.71.Total: $43.48.Dans la municipalité de L'Étand-du-Nord Comme appartenant ù Paul Martin Arscncau un terrain connu il l'ancien cadastre dc l'Ile Crindstonc sous lc numéro 73 subdivision 92 contenant 6.0.0 uercs et au nouveau cadastré île l'Étang-du-Nord sous le numéro 2716 contenant 20425 pd.c.; le numéro 2718 contenant 149600 pd.c.Taxes municipales: $19.95; taxes scolaires: $27.94; frais: $2.78.Total: $50.67.Comme appartenant ù Léo-Paul Bouffard et uutres, un terrain connu ù l'uncien cadastre de l'Ile Grindstone sous les numéros 60 subdivision 29, contenant 8.2.0 acres.No 214 subdivision 159 contenant 3.0.0 acres ct au nouveau cadastre de l'Étang-du-Nord sous le numéro 2830 contenant 370200 pd.c; le numéro 2105 contenant 217750 pd.c.Taxes municipales: $10.82; taxes scolaires: $7.48; frais: $0.75.Total: $19.05.Comme appartenant ù Charles J.Clic varie & Edward un terrain connu nu même ancien cadastre sous le No 132 subdivision 56 contenant 5.2.20 acres et au nouveau cadastre sous lc No 20G2 contenant 543160 pd.c.Taxes municipales: $10.06; taxes scolaires: $42.23; frais: $9.00.Total: $01.95.Comme appartenant à Raoul Chiasson, un terrain connu au même ancien cadastre sous le No 150 subdivision 547 contenant 0.1.0 acres et au nouveau cadastre sous le No 2179 contenant & Jimmy Thorne, Lot No.1157 containing 102400 sq.ft.Municipal taxes: $19.28; school taxes: $74.35.Total: $93.63.As belonging to Jimmy Thorne two lots of land known on the same cadastre as follows: Lot No.1105 containing 166800 sq.ft.Lot No.1162 containing 80030 sq.ft.Municipal taxes: $4.16; school taxes: $9.69.Total: $13.85.As belonging to Maurice \\V.Bouchard a lot of land known on the same cadastre as follows: Lot No.2379 containing 130700 sq.ft.Municipal taxes: $4.13; school taxes: $9.93.Total: $14.06.As belonging to Isaac C.Bourgeois a lot of land known on the same cadastre as follows: Lot No.2335 containing 261360 sq.ft.Municipal tuxes: $15.01; school tuxes: $38.87.Total: $54.48.As belonging to Raymond H.Lapicrrc a lot of land known on the same cadastre as follows: Lot No.1251 containing 81100 sq.ft.Municipal taxes: $48.88; school taxes: $0.98.Total: $49.86.As belonging to Jeffrey Turbide & Ah a lot of lund known on the same cadastre as follows: Lot No.2352 containing 217800 sq.ft.Municipal taxes: $2.43; school taxes: $10.86.Total: $13.29.As belonging to Éric J.Bourgeois a lot of land known on the same cadastre as follows: Lot No.2386 containing 456200 sq.ft.School taxes: $16.42.Total: $16.42.As belonging to Léo-Paul E.Lapicrrc a lot of land known on the same cadastre as follows: Lot No.1551 containing 40300 sq.ft.Municipal taxes: $9.77; school taxes: $33.71.Total: $43.48.In the municipality of L'Étang-du-Nord As belonging to Paul Martin Arscncau a lot of land known on the old cadastre of Grindstone Island under the number 73 subdivision 92 containing 0.0.0 acres and the new cadastre of l'Étang-du-Nord under the number 2716 containing 20425 sq.ft.; the number 2718 containing 149600 sq.ft.Municipal taxes: $19.95; school taxes: $27.94; costs: $2.78.Total : $50.67.As belonging to Léo-Paul Bouffnrd & Others a lot of land known on the old cadastre of Grindstone Island under the numbers 60 subdivision 29 containing 8.2.0 acres, no.214 subdivision 159 containing 3.0.0 ucres and the new cadastre of L'Étang-du-Nord under the number 2830 containing 370260 sq.ft.; the number 2105 containing 217750 sq.ft.Municipal taxes: $10.82; school taxes: $7.48; costs: $0.75.Total: $19.05.As belonging to Charles J.Chevarie & Edward u lot of land known on the same old cadastre under the number 132 subdivision 56 containing 5.2.20 acres and the new cadastre under the number 2062 containing 543160 sq.ft.Municipal taxes: $10.06; school taxes: $42.23; costs: $9.66.Total: $61.95.As belonging to Raoid Chiasson a lot of land known on the same old cadastre under the number 150 subdivision 547 containing 0.1.0 acres und the new cadastre under the number 2179 2818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101* année, n° SO 14140 pd.c; avec bûtisses dessus construites.Taxes municipales: 802.24; taxes scolaires: $84.20; frais: $11.14.Total: $157.58.Comme appartenant a Adelphus Cyr & Vve Vital un terrain connu au même ancien cadastre sous lc No 40 subdivision 767 contenant 10.0.0 acres ct au nouveau cadastre sous le No 2810 contenant 1172100 pd.c; avec bâtisses dessus construites.Taxes municipales: $16.81; taxes scolaires: $147.06; frais: $27.80.Total: $191.67.Comme appartenant il Succession Effeannc Gaudct, un terrain connu au même ancien cadastre sous le No 40 subdivision 16 contenant 6.2.0 acres ct au nouveau cadastre sous le No 2793 contenant 273500 pd.c.Taxes municipales: $21.89; taxes scolaires: $29.66; frais: $11.65.Total: $63.20.Donné à Havrc-aux-Maisons, I.M., ce 5e jour de mai 1969.Ta; secrétaire-trésorier, 29271-20-2-o Mahc-A.Boudreau.Municipalité du comté de Mégantic Avis public est par le présent donné par René Chevrier, secrétaire-trésorier, que les terrains ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique dans le village d'Inverncss, au lieu où le conseil de comté tient ses sessions, MERCREDI, le ONZIÈME jour de JUIN, 1969, à DIX heures du matin, tel que fixé par règlement, à défaut dc paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.Municipalité d'Halifax-Sud Lc lot No 651-24, du cadastre officiel de la paroisse de St-Ferdinand, canton d'Halifax.Connu comme appartenant à Dame Roselyne Bolduc, épouse dc Florian Binette.Taxes dues: $119.23.Le lot No 625-1, du cadastre officiel de la paroisse de St-Ferdinand, canton d'Halifax; sujet à la servitude mentionnée dans le titre d'acquisition.Connu comme appartenant à Roch Lacoursière.Taxes dues: $125.62.Municipalité d'Irlande Nord Un emplacement dc forme rectangulaire, mesurant en mesure anglaise 270 pieds dans ses lignes sud-ouest et nord-est par 100 pieds dans ses lignes sud-est et nord-ouest, ledit emplacement étant une partie du lot No 444 du cadastre officiel du canton d'Irlande et borné comme suit: au sud-est en front parla route No 1, au nord-ouest au sud-ouest, au nord-est par un terrain appartenant à Pierrc-Émile Sénart ou représentants, la ligne sud-ouest dudit emplacement étant située à une distance dc 166 pieds dc la subdivision quarante-sept du lot originaire quatre cent quarante-quatre (444-47) au cadastre officiel du canton d'Irlande, circonstances ct dépendances; sous réserve des mines et droits de mines pour appartenir à qui de droit.Connu comme appartenant ù Marins Blanchard.Taxes ducs: $85.80.Le lot No 444-25, du cadastre officiel du canton d'Irlande.Connu comme appartenant à André Poulin ou son représentant.Taxes ducs: $159.38.containing 14140 sq.ft.with buildings thereon erected; Municipal taxes: $62.24; school taxes: $84.20; costs: $11.14.Total: $157.58.As belonging to Adelphus Cyr & Vve Vital a lot of land known on the same old cadastre under the number 40 subdivision 767 containing 10.0.0 acres and the new cadastre under the number 2810 containing 1172100 sq.ft.with buildings there on erected; Municipal taxes: $16.81; school taxes: $147.06; costs: $27.80.Total: $191.67.As belonging to Estate Effeanne Gaudet a lot of land known on the same old cadastre under the number 40 subdivision 16 containing 6.2.0 acres and the new cadastre under the number 2793 containing 273500 sq.ft.Municipal taxes: $21.89; school taxes: $29.66; costs: $11.65.Total: $63.20.Given at House-Harbour, M.I., this 5th dav of May 1969.Marc-A.Boudreau, 29271-20-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Mégantic Public notice is hereby given by René Chevrier, Secretary-Treasurer, that the lands hereunder mentioned will be sold at public auction, in the village of Inverness, at the place where the county council holds its sittings, on WEDNESDAY, the ELEVENTH day of JUNE, 1969, at TEN o'clock a.m., as enacted by a by-law, in default of payment of taxes due thereon and costs incurred.Municipality of Halifax-South The lot No.651-24, of the official cadastre of the parish of St-Ferdinand, township of Halifax.Known as belonging to Mrs.Roselyne Bolduc, wife of Florian Binette.Taxes due: $119.23.The lot No.625-1, of the official cadastre of the parish of St-Ferdinand, township of Halifax; subject to the servitude mentioned in the title deed.Known as belonging to Roch Lacoursière.Taxes due: $125.62.Municipality of Ireland North An emplacement of rectangular form, measuring 270 feet in its southwest and northeast lines by 100 feet in its southeast and northwest lines, English measure, the said emplacement being a part of the lot No.444, of the official cadastre of the township of Ireland and bounded as follows: in front to the southeast by the road No.1, to the northwest to the southwest, to the northeast by a land belonging to Pierre-Êmile Sénart or representatives, the southwest line of the said emplacement being situated at a distance of 166 feet from the subdivision forty-seven of the original lot four hundred and forty-four (444-47) on the official cadastre of the township of Ireland, circumstances and dependencies; under the reserve of the mines and mining rights in favour of whom they may belong.Known as belonging to Marius Blanchard.Taxes due: $85.80.The lot No.444-25, of the official cadastre of the township of Ireland.Known as belonging to André Poulin or his representative.Taxes due: $159.38. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO 2819 Municipalité d'Irlande Sud o) Une partie du lot No 256, du cadastre officiel du canton d'Irlande, partant du chemin public allant de St-Ferdinand A Black Lake au chemin Chaîné, mesurant 108 pieds le long de ce chemin, 129 pieds en arrière à la profondeur, 150 pieds environ le long du chemin Craig, en arrière et de l'autre côté au résidu du même lot.b) Une pointe de terre faisant partie des lots Nos 255 et 256, du susdit cadastre, de forme irrégulière, étant le terrain compris entre lc chemin Craig en avant, d'un côté au vieux chemin de Black Lake et de l'autre côté au nouveau chemin de Black Lake.c) Une partie du lot No 256, du même cadastre, contenue dans les bornes suivantes: d'un côté au chemin Craig, de l'autre côté au terrain dc Roland Frechette, ou son représentant, au nord à Philippe Garncau à la ligne entre les rangs 4 et 5, et au sud au vieux chemin de Black Lake.Avec toutes les bâtisses érigées sur ces terrains.d) Une partie du lot No 256, susdit cadastre, mesurant 150 pieds de largeur sur le chemin public traversant ce lot (route No 49), à partir dc l'emplacement de François Croteau sur le même lot (représentant Henri Mercier), et allant dans une direction N.-O.; à cette distance mesurant 150 pieds de profondeur dans une direction S.-O.; à cette distance allant dans une direction S.-E.jusqu'au chemin Craig, pour finir à rien à la ligne S.-E.et S.-O.dc l'emplacement de François Croteau au chemin Craig, ce terrain est aussi borné en front au N.-E.partie à la route No 49 et portie à l'emplacement appartenant déjà ù l'acquéreur, d'un côté au N.-O.et en arrière au S.-O.au résidu du terrain d'Emilius Gouin sur le même lot ct nu S.-E.partie A l'emplacement de l'acquéreur ct partie au chemin Craig, la ligne S.-O.du terrain ci-dessus vendu passe ù 5 pieds de la ligne N.-O.dc l'emplacement actuel de François Croteau, en arrière de cet emplacement, pour finir à rien au chemin Craig ù la ligne arrière de l'emplacement actuel de François Croteau, sans bâtisse dessus.Lc terrain vendu est sujet ù servitude de The Bell Telephone Co.of Canada pour sa ligne téléphonique.Lc tout connu comme appartenant ù Claude Croteau pour François.Taxes ducs: $202.82.Municipalité de St-Pierre Baptiste Le lot No 777, du cadastre officiel dc la paroisse de Stc-Sopie, canton d'Halifax; sauf et à distraire dudit lot la partie vendue à Charles-H.Gilbert, par acte enregistré le 5 août 1966, sous le No 112167 et la partie venduc.A Paul Lnmon-tagne, par acte enregistré le 5 août, 1966, sous le No 112168.Connu comme appartenant A Aurélien Nndcau.Taxes dues: $105.29.Municipalité de Ste-Julie Une terre contenant 100 acres en superficie, connue ct désignée au cadastre officiel du canton de Somerset-Nord comme étant la moitié nord-est du lot No 8, bornée à un bout au nord-ouest aux termes du comté de Lotbinière, ù l'autre bout au sud-est au cordon entre les rangs un et deux du canton de Somerset-Nord, d'un côté nu nord- Municipality of Ireland South (a) A part of the lot No.256, of the official cadastre of the township of Ireland, starting from the public road leading from St-Ferdinand to Black Lake to the Chaîné road, measuring 108 feet along that road, 129 feet in rear at the depth, 150 feet about along the Craig's road, in rear and on the other side by the residue of the same lot.(b) A piece of land forming part of the lots Nos 255 and 256, of the above cadastre, of irregular form, being the land included between the Craig's road in front, on one side by the old road of Black Lake and on the other side by the new road of Black Lake.(c) A part of the lot No.256, of the same cadastre, included in the following boundaries: on one side by the Craig's road, on the other side by the property of Roland Frechette, or his representative, to the north by Philippe Garneau at the line between ranges 4 and 5, and on the south by the old road of Black Lake.With all the buildings erected on the above pieces of land.(«£) A part of the lot No.256, of the same cadastre, measuring 150 feet in width on the public road crossing that lot (route No.49), starting from the emplacement of François Croteau on the same lot (representing Henri Mercier) and going in a northwest direction; at that distance measuring 150 feet in depth in a southwest direction; at that distance going in a S.E.direction up to the Craig's road, to finish at nothing at the S.E.and S.W.line of the emplacement of François Croteau to the Craig's road, this piece of land is also bounded in front to the N.E.partly by the route No.49 and partly by the emplacement already belonging to the purchaser, on one side to the N.W.and in rear to the S.W.by the residue of the property of Émilius Gouin on the same lot and to the S.E.partly by the emplacement of the purchaser and partly by the Craig's road, the S.W.line of the above land sold passes at 5 feet of the N.W.line of the actual emplacement of François Croteau, in rear of that emplacement, to finish at nothing at the Craig's road at the rear line of the actual emplacement of François Croteau, without building.The land sold is subject to the servitude of The Bell Telephone Co.of Canada.The whole known as belonging to Claude Croteau for François.Taxes due: $262.82.Municipality of St-Pierre Baptiste The lot No.777, of the official cadastre of the parish of Ste-Sophie, township of Halifax; save and except of the said lot the part sold to Charles-H.Gilbert, by deed registered the 5th of August, 1966.under the No.112167 and the part sold to Paul Lamontngne, by deed registered the 5th of August, 1966, under the No.112168.Known as belonging to Aurélien Nadeau.Taxes due: $105.29.Municipality of Ste-Julic A farm containing 100 acres in superficies known and designated on the official cadastre of the township of Somerset-North, as being the northeast half of the lot No.8, bounded at one end to the northwest by the farms of the county of Lotbinière, at the other end to the southeast by the division line between ranges 1 and 2 2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, h' SO est au lot No.7 et de l'autre côté au sud-ouest au résidu du lot No 8, sans bâtisse.Connue comme appartenant à Yvon Bradette.Taxes dues: $11.29.Une terre située dans le premier rang du canton de Somerset-Nord, mesurant environ 5 arpents de largeur par la profondeur du rang, connue et désignée au cadastre officiel du canton de Somerset-Nord comme étant le moitié nord-est du lot No 11, bornée aux deux bouts aux cordons des rangs, d'un côté au nord-est au lot No 10 et de l'autre côté au sud-ouest au résidu dudit lot No 11 appartenant ù La Couronne ou représentants.Connue comme appartenant à Henri S.Côté.Taxes dues: $19.64.Une partie du lot No 409, du cadastre officiel du canton de Somerset-Nord, contenant environ 100 acres en superficie, bornée d'un bout au nord-ouest par le 8ième rang, au sud-est par le ore du dixième rang, d'un côté au nord-est par une route anciennement tracée, et au sud-ouest par le terrain d'Emile Lemclin, ou son représentant.Ce terrain mesure environ 45 pieds de largeur au nord-ouest et environ 10 ou 11 arpents de largeur au sud-est, le tout plus ou moins et sans garantie de mesures précises, Sujette à la réserve des mines et droits de mines en faveur de qui de droit.Connue comme appartenant à Louis-Philippe Gagné.Taxes dues: $46.67.Le lot No 169-1, du cadastre officiel du canton de Somerset-Nord, avec bâtisse dessus construite.Avec droit de passage sur une partie du lot No 169 non subdivisé du susdit cadastre, tel que le tout est établi dans les titres s'y rapportant.Connu comme étant lc < Manoir Ste-Julie».Taxes dues: $1,102.71.Municipalité de Thetford Sud Le lot No 25-C-2, du 3e rang, du cadastre officiel du canton de Thetford, avec bâtisse dessus construite; sous la réserve des mines à qui de droit.Connu comme appartenant à succession Aurore Giguère (La Curatelle Publique, 680 Ste-Catherine Ouest, Montréal, P.Q.).Taxes dues: $283.94.Municipalité de Plessisville Paroisse Les 3 arpents de front sur la profondeur du rang 5, étant les 3 arpents nord-ouest du lot No 437, du cadastre officiel du canton de Somerset-Sud, bornés en front au nord-ouest au lot No 436, en arrière au sud-est au résidu du même lot, appartenant à Euclide Ferron, d'un côté au sud-ouest au lot No 439 et de l'autre côté au nord-est au lot No.333, contenant 63 acres en superficie, plus ou moins.Connus comme appartenant à Yvon Lachance.Taxes dues: $285.43.P.I.C.S.O., 7e rang, du cadastre officiel du canton de Stanfold, contenant 12 acres en superficie.Connu comme appartenant à Charles Trépa-nier.Taxes dues: $5.00.of the township of Somerset-North, on one side to the northeast by the lot No.7 and on the other side to the southwest by the residue of the lot No.8 without building.Known as belonging to Yvon Bradette.Taxes due: $11.29.A farm situated in the first range of the township of Somerset-North, measuring about 5 arpents in width by the depth of the range, known and designated on the official cadastre of the township of Somerset-North as being, the northeast half of the lot No.11, bounded at both ends by the division lines of the ranges, on one side to the northeast by the lot No.10 and on the other side to the southwest by the residue of the same lot No.11 belonging to the Crown or representatives.Known as belonging to Henri S.Côté.Taxes due: $19.64.A part of the lot No.409, of the official cadastre of the township of Somerset-North, containing about 100 aces in superficies, bounded at one end to the northwest by the 8th range, to the southeast by the Gore of the 10th range, on one side to the northeast by an old road and to the southwest by the land of Emile Lemeliii or his representative.That land measures about 45 feet in width to the northwest and about 10 or 11 arpents in width to the southeast, the whole more or less and without guarantee of precise measurements.Subject to the reserve of mines and mining rights in favour of whom they may belong.Known as belonging to Louis-Philippe Gagné, Taxes due: $46.67.The lot No.169-1, of the official cadastre of the township of Somerset-North, with building thereon erected.With a right of way on a part of the lot No.169 not subdivided of the above cadastre, as the whole appears in the title deeds.Known as being the \"Manoir Ste-Julie\".Taxes due: $1,102.71.Municipality of Thetford South The lot No.25-C-2, of the 3rd range, of the official cadastre of the township of Thetford, with building thereon erected; under the reserve of the mines in favour of whom they may belong.Known as belonging to Estate Aurore Giguère (La Curatelle Public, 680 Ste-Catherine ouest, Montreal, P.Q.).Taxes due: $283.94.Municipality of the parish of Plessisville The 3 arpents in front on the depth of the 5 th range, being the northwest 3 arpents of the lot No.437, of the official cadastre of the township of Somerset-South, bounded in front to the northwest by the lot No.436, in rear to the southwest by the residue of the same lot, belonging to Euclide Ferron, on one side to the southwest by the lot No 439 and on the other side to the northeast by the lot No.333, containing 63 acres in superficies, more or less.Known as belonging to Yvon Lachancc.Taxes due: $285.43.P.I.C.S.O., 7th range of the official cadastre of the township of Stanfold, containing 12 acres in superficies.Known as belonging to Charles Trépanicr.Taxes due: $5.00. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2821 Ptie No 2 0., du 7e rang, du cadastre officiel du canton de Stanfold, contenant 36 acres en superficie.Connue comme appartenant à Charles Trépa-nier.Taxes dues: $10.24.Une partie du lot No 268, du cadastre officiel «lu canton de Somerset-Sud, sur le bord de lu rivière Blanche, de figure irrégulière, mesurant 161 pieds de largeur en avant, sur lc bord dc la rivière Blanche, et 173 pieds de largeur en arrière, par 35 pieds de profondeur dans sa ligne sud-est ct 100 pieds dc profondeur dans sa ligne nord-ouest, lc tout plus ou moins, mesure anglaise, bornée en avant au nord-est à la rivière Blanche, en arrière au sud-ouest au chemin des chalets, d'un côté au nord-ouest au terrain d'Hervé Le-comtc ct de l'autre côté au sud-est à une lisière de terrain de 4 pieds de largeur appartenant à Jean-Paul Deniers, ou son représentant, ct adjoignant au terrain dc Theobald Poulin du' côté sud-est, avec chalet dessus construit, circonstances ct dépendances.Avec droit dc passage dans le chemin privé conduisant du chemin public à l'emplacement de chalet présentement vendu.Connue comme appartenant à Jacques Perron.Taxes dues: $20.53.Une partie du lot No 268, du cadastre officiel de la municipalité dc Somerset-Sud (ou Canton de Somerset-Sud), mesurant 75 pieds dc largeur du nord-ouest au sud-est par toute la profondeur comprise entre les emplacements de chalets dc MM.Hervé Lécomtc ct Raymond Gendron et le lot No 267 appartenant ù Narcisse Vigncault, bornée en front au nord-est aux emplacements faisant partie du même lot ct appartenant à Hervé Lccomtc et Raymond Gendron, en arrière uu sud-ouest au lot No 267, d'un côté au sud-est par une autre partie du même lot appartenant ù Gérard Dubois et de l'autre côté au nord-ouest par le résidu du même lot No 268 restant la propriété du vendeur.Avec le camp érigé sur ce terrain, circonstances ct dépendances.Le terrain ci-dessus est sujet au droit dc passage dans le chemin existant actuellement, pour les emplacements de chalets et leurs propriétaires, selon les titres s'y rapportant.Avec droit dc passage pour l'acquéreur ou ses représentants dans un chemin réservé de 4 pieds dc largeur, entre les emplacements de Jeun-Paul Côté ct Raymond Gendron, pour lui permettre de communiquer a la rivière, le tout constitué à titre de servitude perpétuelle sur une partie du même lot du même cadastre.Connue comme appartenunt i\\ Jacques Perron.Taxes dues: $62.34.Une maison érigée sur une partie du lot No 2, du 5e rang du ««dastre officiel «lu eau ton de Stanfold.Connue comme appartenant ù Roger Vigncault.Taxes dues: $127.64.La partie ouest du lot No 8, du 5c rang, du cadastre officiel du canton de Stanfold, contenant 100 acres en superficie.Connue comme appartenant ù Roger Vigncault.Taxes ducs: $32.39.Les lots Nos 114-1, 114-2, 114-3, 114-4, 114-5, 114-6, 114-7, 114-8, 114-9, 114-10, 114-11, 114-12, 114-13, 114-14, 114-15, 114-16, 114-17, 114-18, 114-19, 114-20, 114-21, 114-22, 114-23, 114-24, 114-25, 114-26, 114-27, 114-33, 114-34, 114-35, 114-41, 114-42, 114-43, 114-44, 114-45, 114-47, 115-2, 115-3, 115-5, 115-6, 115-7, 115-8, 115-9, 115-10, 115-11, 115-12, 115-13, 115-14, 115-15, 115-16, 115-17, 115-18, 115-19, 115-20, 115-23, 115-24, 115-26, 115-27, 115-28, 115-29, 115-30, 115-31, 115-32, 115-33, Ptie No.2 W., 7th range, of the official cadastre of the township of Stanfold, containing 36 acres in superficies.Known as belonging to Charles Trépanier.Taxes due: $10.24.A part of the lot No.268, of the official cadastre of the township of Somerset-South, on the shore of the River Blanche, of irregular form, measuring 161 feet in width in front on the shore of Rivière Blanche, and 173 feet in width in rear by 35 feet in depth in its southeast line and 100 feet in depth in its northwest line, the whole more or less, English measure, bounded in front to the northeast by the Rivière Blanche, in rear to the southwest by the road of the cottages, on one side to the northwest by the lands of Hervé Lecomte and on the other side to the southeast by a strip of land of 4 feet in width belonging to Jean-Paul Demers or representative, and adjoining the land of Theobald Poulin on the southeast side, with the cottage thereon erected, circumstances and dependencies.With the right of way in.the private road leading from the public road to the land presently sold.Known as belonging to Jacques Perron.Taxes due: $20.53.A part of the lot No.268 of the official cadastre of the municipality of Somerset-South (or township of Somerset-Soutli), measuring 75 feet in width from the northwest to the southeast by all the depth included between the cottage emplacements of MM.Hervé Lecomte et Raymond Gendron and the lot No 267 belonging to Narcisse Vigneault, bounded in front to the northeast by the emplacements, forming part of the same lot and belonging to Hervé Lecomte and Raymond Gendron, in rear to the southwest by the lot No.267, on one side to the southeast by an other part of the same lot belonging to Gérard Dubois and on the other side to the northwest by the residue of the same lot No.268 remaining the property of the vendor.With a camp erected on that land, circumstances and dependencies.The above land is subject to the right of way in the road already existing for the cottage emplacements and their owners according to the titles.With a right of way for the purchaser or his representatives in a road reserved of 4 feet wide, between the emplacements of Jean-Paul Côté and Raymond Gendron, to allow him to communicate to the river, the whole constituted as a perpetual servitude on.a part of the same lot of the same cadastre.Known as belonging to Jacques Perron.Taxes due: $62.34.A house erected on a part of the lot No.2, in the 5th range of the official cadastre of the township of Stanfold.Known as belonging to Roger Vigneault.Taxes due: $127.64.The west part of the lot No.8, in the 5th range, of the official cadastre of the township of Stanfold, containing 100 acres in superficies.Known as belonging to Roger Vigncault.Taxes due: $32.39.The lots Nos.114-1, 114-2, 114-3, 114-4, 114-5, 114-6, 114-7, 114-8, 114-9, 114-10, 114-11, 114-12, 114-13, 114-14, 114-15, 114-16, 114-17, 114-18, 114-19, 114-20, 114-21, 114-22, 114-23, 114-24, 114-25, 114-26, 114-27, 114-33, 114-34, 114-35, 114-41, 114-42, 114-43, 114-44, 114-45, 114-47, 115-2, 115-3, 115-5, 115-6.115-7, 115-8, 115-9, 115-10, 115-11, 115-12, 115-13, 115-14, 115-15, 115-16, 115-17, 115-18, 115-19, 115-20, 115-23, 115-24, 115-26, 115-27, 115-28, 115-29, 115-30, 115-31, 115-32, 115-33, 2822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 19G9, 101' année, n° 20 115-35, 115-45, 115-49, 115-50, 115-51, 115-52, 115-53, 118-4, 118-6, 118-15, 118-24, 118-33, 118-38, 118-52, 119-1, 119-3, 119-4, 119-8, 119-9, 119-12, 119-19, 119-23, 119-40, 119-42, 119-43, 119-44, 119-46, 119-47, 120-23, 120-25, 120-26, 120-29, 120-43, 120-49, 120-50, 120-54, 120-58, 120-60, 120-65, 120-68, 120-69, 120-70, 120-71, 120-72, 120-73, 120-74, 120-75 et 120-76, du cadastre officiel de la municipalité dc Somerset-Sud, canton du même nom.Ensemble la maison érigée sur lc lot No 119-3 susdit.Sujets ces terrains à toutes les servitudes de passage et autres, suivant les titres.Connus comme appartenant à « Domaine Venise Inc.».Taxes dues: $465.24.Inverness, lc 28 avril 1969.Le secrélaire-lrésorier de la Corporation du comté de Mégaidic, 29152-19-2-0 René Chevrier.115-35, 115-45, 115-49, 115-50, 115-51, 115-52, 115-53, 118-4, 118-6, 118-15, 118-24, 118-33, 118-38, 118-52, 119-1, 119-3, 119-4, 119-8, 119-9, 119-12, 119-19, 119-23, 119-40, 119-42, 119-43, 119-44, 119-46, 119-47, 120-23, 120-25, 120-26, 120-29, 120-43, 120-49, 120-50, 120-54, 120-58, 120-60, 120-65, 120-68, 120-69, 120-70, 120-71,120-72,120-73,120-74,120-75 and 120-70, of the official cadastre of the municipality of Somerset-South, township of the same name.Including the house erected on the said lot No.119-3.Subject all those lots of land to all the servitudes of right of way and others, according to the titles.Known as belonging to \"Domaine Venise Inc.\".Taxes due: $465.24.Inverness, April 28, 1969.René Chevrier, Secretary-Treasurer of the Corporation 29152-19-2-0 of the county of Mégantic.Chartes \u2014 demandes d'abandon de Canadian Stockholders Investment Corporation Avis est donné, par les présentes, que « Canadian Stockholders Investment Corporation », compagnie incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives de la province dc Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, suivant les dispositions de l'article 20 de la Loi des compagnies.Donné ù Montréal, Québec, ce 30c jour d'avril 1969.Le secrélaire-lrésorier, 29185-0 C.L.Larock.J.Golden Co.En vertu des dispositions dc la Loi des compagnies, la compagnie « J.Golden Co.», donne avis par les présentes qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives pour fuirc accepter l'abandon de sa charte et son annulation à compter de la date qu'il fixera.Montréal, le 1er mai 1969.Le président, 29186 Joseph Golden.A.N.K.A.Investment Ltd.Avis est donné que « A.N.K.A.Investment Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, lc 5 moi 1969.L'avocat de la requérante, 29224-o Blank a Gyulai.Andalou Haute Coiffure inc.Prenez avis que la compagnie « Andalou Haute Coiffure inc.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 22 avril, 1969.Le procureur de la compagnie, 29226-0 André Antonuk.Charters \u2014 Application for Surrender of Canadian Stockholders Investment Corporation Notice is hereby given that \"Canadian Stockholders Investment Corporation\", a company incorporated under the provisions of Part I of the companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of section 26 of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 30th day of April, 1969.C; L.Larock, 29185-0 Secretary-Treasurer.J.Golden Co.Under the provisions of the Companies Act.\"J.Golden Co.\", hereby gives notice that it will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation as and from a date to be fixed by him.Montreal, May 1st, 1969.Joseph Golden, 29186-0 President.A.N.K.A.Investment Ltd.Notice is hereby given that \"A.N.K.A.Investment Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, May 5, 1969.Blanka Gyulai, 29224-0 Attorney for petitioner.Andalou Haute Coiffure inc.Notice is hereby given that \"Andalou Haute Coiffure inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, April 22, 1969.André Antonuk, 29226 Attorney for the company. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 19G9, Vol.101, No.20 Ary Ltd.Avis est donné que « Ary Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies ct ayant son siège social en la ville dc Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives dc la province île Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, lc 5 mai 1969.L'avocat de la requérante, 29225-0 Blanka Gyulai.Bcuvcr Development Inc.l'rcnc/.avis que la compagnie < Bcuvcr Development Inc.», demandera uu ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives dc la province dc Québec, la permission d'abandonner sa charte.I.e procureur de la compagnie, 29227-o Me Guy Lacoste, notaire.(.irai Britain and Canada Investment Corporation Avis est donné, pur les présentes, que « Great Britain and Canada Investment Corporation», compagnie incorporée en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives de la province dc Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa churtc, suivant les dispositions dc l'article 26 dc la Loi des compagnies.Daté ù Montréal, Québec, ce 30e jour d'avril 1969.Le secrétaire-trésorier, 29187-0 C.L.Larock.I lui llnil Company Limited Avis est pur les présentes donné que lu cor|M>-intion « Hurlbut Company Limited », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc lu province de t\\juél>cc [>our fuire accepter l'abandon de sa charte et son annulation à compter dc la date qu'il fixera.Le président, 29188 Betty H.Dixon.O.U.Léger inc.Avis est par les présentes, donné que lu compagnie « O.U.Léger inc.», une corporation constituée, en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social ù Sherbrooke, Que., s'adressera au ministre des institutions financières, coin pu -gnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté, ce 5c jour de mars 1969.Lc président, 29189-0 Claude Leg eh.Boire & Frères inc.Prenez avis que la compagnie « Boire & Frères inc.», demandera uu ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, lc 5 mai 1969.Le président, 29228-0 Paul Boire.2823 Ary Ltd.Notice is hereby given that \"Ary Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Company Act.Montreal, May 5, 1969.Blanka Gyulai, 29225-o Attorney for petitioner.Beaver Development Inc.Notice is hereby given that \"Beaver Development Inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter.Me Guy Lacoste, notary, 29227 Attorney for the company.Great Britain and Canada Investment Corporation Notice is hereby given that \"Grcut Britain and Canada Investment Corporation\", a company incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of section 26 of the Companies Act.Dutcd at Montreal, Quebec, this 30th day of April, 1969.C.L.Larock, 29187-0 Secretary-Treasurer.Mm -11 > i ¦ i Company Limited Notice is hereby given that \"Hurlbut Company Limited\", u corporation constituted under the Companies Act und having its head office in tin-City of Montreal, will apply to Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation on and from a dutc to be fixed by him.Betty H.Dixon, 29188-0 President.O.I .Léger inc.Notice is hereby given that \"O.U.Léger inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at Sherbrooke, Que., will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated, this 5th duy of March, 1969.Claude Leuek, 29189 President.Boire & Frères inc.Notice is hereby given that \"Boire & Frères inc.\" will apply the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its cliarter.Montreal, May 5, 1969.Pall Boiiik, 29228 President. 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° SO Placements Adjutor Amyot ltée Avis est par les présentes donné que « Placements Adjutor Amyot ltée», une corporation incorporée en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Québec, district de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Daté ù Québec, ce 2e jour de mai, 1969.Les procureurs de la compagnie, Tremblay, Beauvais, Boucharu, 29190-o Garneau, Truciion & Morisset.Canadian Air l'unips Ltd.Avis est par les présentes donné «pic lu compagnie « Canadian Air Pumps Ltd.», constituée en corporation en vertu de lu Loi des compugnics ct ayant son siège social dans la ville dc Montréal, s^adressera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 27c jour d'avril 1969.Le secrétaire, 29229 Steve J.Gabon.Daigneault & Frère inc.Prenez avis que la compagnie « Duigneuult & Frère inc.», demandera uu ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Lc procureur de la compagnie, 29230-o Claude Trudeau.Pucellu Investment Co.Avis est par les présentes donné que lu compagnie < Fncella Investment Co.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province dc Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi «les compagnies.Daté ù Montréal, le 6c jour dc murs 1969.Le secrétaire, 29231 Jack Ilovitch.Gordon Manufacturing Co.Ltd.Avis est par les présentes donné que lu compagnie « Gordon Manufacturing Co.Ltd.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté ù Montréal, ce deuxième jour d'avril 1969.Le secrétaire, 29232 A.1.Gordon.Imcra Construction Ltd.Prenez avis que la compagnie « I niera Construction Ltd.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 5 mai 1969.Le procureur de la compagnie, 29233-o Me Yvon Perras, cr.Placements Adjutor Amyot ltée Notice is hereby given that \"Placements Adjutor Amyot ltée\", a company incorporated under Part I of the Companies Act, and having its head office at Québec, district of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Dated at Québec, this 2nd day of May, 1969.Tremblay, Beauvais, Bouchard, Garneau, Truciion & Morisset, 29190 Attorney for the company.Canadian Air Pumps Ltd.Notice is hereby given that \"Canadian Air Pumps Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave lo surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 27th day of April, 1909.Steve J.Gabon, 29229-o Secretary.Duigncault & Frère inc.Take notice that \"Daigneault & Frère inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Claude Trudeau, 29230 Attorney for the company.Pucellu Investment Co.Notice is hereby given that \"Facclla Investment Co.\", incoriwrated under the Companies Act, and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of tin-province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 6th day of Murch, 1969.Jack Ilovitcii, 29231-o Secretary.Gordon Manufacturing Co.Ltd.Notice is hereby given that \"Gordon Manufacturing Co.Lttl.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this second day of April, 1969.A.J.Gordon, 29232-0 Secretary.Iniera Construction Ltd.Notice is hereby given that \"Imera Construction Ltd.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, May 5, 1969.Me Yvon Peuhas, u.c., 29233 Attorney for the Company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO 2825 Indépendant Hungarian Protestant Church in Montreal Avis est donné que « Indépendant Hungarian Protestant Church in Montreal », une congrégation constituée en vertu dc la Loi des Compagnies ct ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec,, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dis-]H>.sitions de la Loi des Compagnies.Montréal, le 5 mai 1969.L'arocal de la rcquèratUe, 29234-o I! i.anka Gyulai.Poissant limitée Avis est par les présentes donné que la compagnie « Poissant limitée », corporation légalement constituée, 'ayant une place d'affaires dans les cité ct district de Trois-Rivières, province dc Quelle, ct constituée en vertu de la Loi des compagnies, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Montréal, le 29 avril 1969.Le procureur, 29236-0 Olivier Gauthier.Servitor inc.Avis est par les présentes donné que lu compagnie « Servitor inc.», corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires dans les cité ct district dc Trois-Rivières, province dc Québec» et constituée en vertu dc la Loi des compagnies, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 29 avril 1969.Le procureur, 29236-0 Olivier Gauthier.Tiber Investments Limited Avis est donné qu'en vertu des dispositions delà Loi des compagnies, * Tiber Investments Limited » donne par les présentes avis qu'elle feru application au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour l'acceptation dc l'abandon dc sa charte, ainsi que sa cancellation ù compter d'une date à être fixée par ce dernier.Montreal, le 5 mai 1969.Lc président, 20237-o Carl Wott.Trout Lake Estates Inc.Domaines du Lac à la Truite inc.Avis est par les présentes donné que « Trout Luke Estates Inc.\u2014 Domaines du Lac à la Truite inc.», ayant son bureau-chef, en la cité dc Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner ses lettres patentes, ù partir de la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté il Montréal, ce 6c jour de mai, 1969.Les procureurs de la requérante, 29265m Biega, Beaureoahd & Kooimax.Indépendant Hungarian Protestant Church in Montreal Notice is hereby given that the \"Indépendant Hungarian Protestant Church in Montreal\", a congregation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act Montreal, May 5, 1969.Blanka Gyulai, 29234-o Attorney for Petitioner.Poissunt limitée Notice is hereby given that \"Poissant limitée\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the city and district of Three Rivers, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter, according to provisions of the Companies Act.Montreal, April 29, 1969.Olivier Gauthier, 29235-0 Attorney.Servitor inc.Notice is hereby given that \"Servitor inc.\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the city and district of Three Rivers, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter, according to provisions of the Companies Act.Montreal, April 29, 1969.Olivier Gauthier, 29236-0 Attorney.Tiber Investments Limited Under the provisions of the Companies Act, \"Tiber Investments Limited\" hereby gives notice that it will make application to the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives for the acceptance of the surrender of its charter and its cancellation as and from a date to be fixed by him.Montreal, May 5, 1969.Carl Wott, 29237-o President.Trout Lake Estates Inc.Domaines du Lac à la Truite inc.Notice is hereby given that \"Trout Lake Estates Inc.\u2014 Domaines du Lac à la Truite inc.\", having its head office ut the City of Montreal, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 6th day of May 1969.Uiega, Beauregard & Kooimax, 29265-0 Attorneys for Petitioner. 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° 20 George I'll Mips Corporation Prenez avis que la compagnie * George Philips Corporation » demandera au ministère des institutions financières, compagnies ct coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 5 mai 1969.Le président, 29266-o Thérèse) O'Reilly.Autosport ltée La compagnie « Autosport liée » donne avis par les présentes qu'elle demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec la permission d'abandonner sa charte à compter d'une dute ù être fixée.Montréal, lc 8 mai 1969.La secrétaire, 29300-O Monique Durand.Buyer ltée Prenez avis que « Boycr ltée « demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc la province, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 23 avril 1969.Les procureurs de la compagnie, LÉTOI.'iineau, quinlan, forest, raymond, 29301-O Letouhneau, Magnan & Roy.Mario Brcic inc.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « Mario Brcic inc.» une corporation constituée en vertu dc la Loi des compagnies et ayant son siège social à Sherbrooke, Que., s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la I/oi des compagnies.Daté, ce 7e jour dc mai 1969.Lc président, 29302-o Mario Brcic La Cie dc Gestion Rouberville limitée Prenez avis que la compagnie « La Cic de (ïestion Rouberville limitée » demandera nu ministre des institutions finuncières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 7 mai 1969.Le président, 29303-o Wilfrid Berlinguette.Club Optimiste St-Adelpbe St-Stunislas inc.Prenez avis que la corporation « Club Optimiste St-Adelphc St-Stanislus inc.» demandera uu ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.St-Adelphc, le 3 mai 1969.Le secrétaire, 29304-o Yvon Brouillette.La Compagnie dc Téléphone dc Rishorough Prenez avis que « La Compagnie de Téléphone de Risborough », corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires à St-Ludger, comté de Frontenac, district dc Beauce, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 29305-o Cliche & Laflamme.George Philips Corporation Notice is hereby given that \"George Philips Corporation\" will apply to the Financial Institutions, Companies and Cooperatives Department Act, for leave to surrender its charter.Montreal, May 5, 1969.Thérèse O'Reilly, 29266-0 President.Aulospurt ltée The company \"Autosport ltée\" hereby gives notice that application will be made to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter at a date to be fixed.Montreal, this May 8, 1969.Monique Durand, 29300 , Secretary.Buyer ltée Notice is hereby given that \"Boycr ltée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province to surrender its charter.Montreal, April 23rd, 1969.létouhneau, quinlan, forest, Raymond, Létourneau, Magnan & Roy, 29301 Attorneys for petitioner.Mario Brcic inc.Notice is hereby given that \"Mario Brcic inc.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at Sherbrooke, Que., will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated, this 7th duy of May, 1909.Mario Brcic, 29302 President.La Cie de Gestion Rouberville limitée Notice is hereby given that \"La Cic de Gestion Rouberville limitée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charier.Montreal, May 7, 1909.Wilfrid Bekmnguette, 29303 President.Club Optimiste Si - Adelphe St-Stanislas inc.Notice is hereby given that the corporation \"Club Optimiste St-Adelphe St-Stanislas inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.St-Adelphc, May 3, 1969.Yvon Brouillette, 29304 Secretary.La Compagnie de Téléphone dc Risborough Notice is hereby given that \"La Compagnie de Téléphone de Risborough\", a corporation legally incorporated, having its place of business at St-Ludger, county of Frontenac, district of Beauce, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Cliche & Laflamme, 29305 Attorneys for the Company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO Gcrson Development Corp.Avis est par les présentes donné que « Gerson Development Corp.», qui a son bureau principal dans la cité et district de Montréal, province de Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies.Montréal, le 8 mai 1969.Le procureur, 29306-o Eric S.Helfield.Goyer Avenue Luncheonette Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Goyer Avenue Luncheonette Ltd.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies ct ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir lu permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté ù Montréal, le 10e jour de juin 196S.La secrétaire, 29307 Jeannette Houle Michaud.Hôpital Stc-Clairc inc.Prenez avis que la compagnie « Hôpital Stc-< 'lairc inc.», va demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives ¦ le la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la requérante, 29308-o Claude Roter, Notaire.Manchester Development Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Manchester Development Ltd.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville dc M uni real, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives dc ln province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 7 mai 1969.Le secrétaire, \u202229309 Otto Horner.National Intercom Ltd.Avis est par les présentes donné que lu compagnie * National Intercom Ltd.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner su charte.Les avocats, Ueauciiemix, Valiquette & Gekvais.29311-0 St.Jovitc Realties & Construction Inc.Avis est par les présentes donné'que lu compagnie « St.Jovite Realties & Construction Inc.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social ù Duvernay, dans le district dc Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions dc la Loi des compagnies.Donné ù Montréal, le lie jour d'avril 1969.Le procureur de la compagnie, 29314 John Hf.rschorn, eu.2827 Gerson Development Corp.Notice is hereby given that \"Gerson Development Corp.\", having its head office in the city and district of Montreal, Province of Québec, will make application for leave to surrender its charter, in accordance with the provisions of the Companies Act.Montreal, May 8, 1969.Eric S.Helfield, 29306-o Attorney.Goycr Avenue Luncheonette Ltd.Notice is hereby given that \"Goyer Avenue Luncheonette Ltd.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 10th day of June, 1968.Jeannette Houle Michaud, 29307-o Secretary.Hôpital Stc-Claire inc.Notice is hereby given that \"Hôpital Ste-Claire inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Claude Royek, Notary, 29308 Attorney for the Petitioner.Manchester Development Ltd.Notice is hereby given that \"Manchester Development Ltd.\", incorporated under the Companies Act, und having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, May 7, 1969.Otto Hokner, 29309-o Secretary.National Intercom Ltd.Notice is hereby given that the company \"National Intercom Ltd.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives, for leave to surrender its charter.Heauchemin, Valiquette & Gervais, Advocates.29311 St.Jovitc Realties & Construction Inc.Notice is hereby given that \"St.Jovite Realties & Construction Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Duvcrnay, in the district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this llth dav of April, 1969.John Herscuorn, q.cv, 29314-0 Attorney for the Company. 2828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101 \u2022 année, n° SO N.Robinson Construction & Equipment Co.Ltd.Prenez avis que la compagnie * N.Robinson Construction & Equipment Co.Ltd.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les -procureurs de la compagnie, 29313-o Dagenais & Dagenais, avocats.Salon Funéraire La Sarre inc.Prenez avis que la compagnie < Salon Funéraire La Sarre inc.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, Cinq-Mars, Grimard 29315-0 & Bélanger.Mister Steers Chuck Wagon Inc.Avis est par les présentes donné que < Mister Steers Chuck Wagon Inc.» ayant son bureau chef dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner ses lettres patentes, ù partir de la date qu'il lui plaira de déterminer.Date ii Montréal, ce 30c jour d'avril 1969.Les procureurs de la requérante, 29310 Stein & Stein.Power-Magic Company Ltd.La compagnie « Power-Magic Company Ltd.» donne avis par les présentes qu'elle demandera au ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte ù compter d'une date à être fixée.Montréal, le 9 mai 1969.Le secrétaire, 29312-0 Jean-Paul Gagné.N.Robinson Construction & Equipment Co.Ltd.Notice is hereby given that \"N.Robinson Construction & Equipment Co.Ltd.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dagenais & Dagenais, advocates, 29313 Attorneys for the Company.Salon Funéraire La Sarre inc.Notice is hereby given that \"Salon Funéraire La Sarre inc.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Cinq-Mars, Grimard & bélanger, 29315 Attorneys for the Company.Mister Steers Chuck Wagon Inc.Notice is hereby given that \"Mister Steers Chuck Wagon Inc.\" having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives of the province of Québec, for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 30th day of April 1909.Stein & Stein, 29310-o Attorneys for petitioner.Power-Magic Company Ltd.The company \"Power-Magic Company Ltd.\" hereby gives notice that application will be made to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec for leave to surrender its charter ut a date to be fixed.Montreal, this May 9, 1969.Jean-Paul Gagné, 29312 Secretary.Divers Compagnies Miscellaneous Companies Acme Pontiac-Buick incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé le 1er avril 1969 le règlement numéro 24 de la compagnie « Acme Autoservice ltée », changeant son nom en celui de « Acme Pontiac-Buick incorporée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29191-o 10492-56 Les Breuvages Crépin inc.Crépin Beverages Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 21 avril 1969 le règlement numéro 5 de la compagnie « Richer & Frère ltée », changeant son nom en celui de « Les Breuvages Crépin inc.\u2014 Crépin Beverages Inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29194-o 10830-53 Acme Pontiac-Buick incorporée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 1, 1969, approved the by-law No.24 of the company \"Acme Autoservice ltée\", changing its name into that of \"Acme Pontiac-Buick incorporée\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29191 10492-56 Les Breuvages Crépin inc.Crépin Beverages Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 21, 1969, approved the by-law No.5 of the company \"Richer & Frère ltée\", changing its name into that of \"Les Breuvages Crépin inc.\u2014 Crépin Beverages Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29194 10830-53 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2829 Affiliated Factors Corp.Avis est donné que la compagnie « Affiliated Factors Corp.» a changé le nombre de ses administrateurs de 8 à 12.Le secrétaire, Gordon Brown.29192 222-64 Bernai Laboratories Ltd.Avis est donné que la compagnie « Bernul Laboratories Ltd.» a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Pearl Clarke.29193 10613-56 Consolidated Plywood Corporation Avis est donné que la compagnie « Consolidated Plywood Corporation » a changé lc nombre de ses administrateurs de 6 à 7.Le secrétaire, J.Frédéric Paré.29195 12528-51 U.L.Dixon Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé le 11 avril 1969 le règlement numéro B de la compagnie « Fournier and Dixon Ltd.», changeant son nom en celui de < R.L.Dixon Ltd.».I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29196-0 4291-65 Dynamic Welding Co.Ltd.Avis est donné que « Dynamic Welding Co.Ltd.» a changé le nombre de ses administrateurs \u2022i à 3.Le secrétaire, VlTA fundaro.29197 3453-65 Jack's Dress Company Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 9 avril 1969 le règlement numéro 13 de la compagnie < Boutique Maggie inc.», changeant son nom en celui de « Jack's Dress Company ».I.e sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29198-o 5202-68 Métro Caravane ltée Metro Caravan Ltd.Avis est donné que la compagnie « Métro Caravane ltée \u2014 Metro Caravan Ltd.», a fixé le nombre de ses administrateurs ù 4.\" Le secrétaire, Gilbert Currier.29201-o 1687-68 Morgan Insurance Services Ltd.Les Services d'Assurance Morgan ltée Avis est donné que « Morgan Insurance Services Ltd.\u2014 Les Services d'Assurance Morgan liée » a changé lc nombre de ses directeurs, de Il à 13.Le secrétaire, E.W.Rowat.29203 6379-47 Affiliated Factors Corp.Notice is given that \"Affiliated Factors Corp.\" has changed the number of its directors from 8 to 12.Gordon Brown, Secretary.29192-0 222-64 Bernai Laboratories Ltd.Notice is given that \"Bernai Laboratories Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Pearl Clarke, Secretary.29193-0 10613-56 Consolidated Plywood Corporation Notice is given that \"Consolidated Plywood Corporation\" has changed the number of its directors from 6 to 7.J.Frédéric Paré, Secretary.29195-0 12528-51 It.L.Dixon Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 11, 1969, approved the by-law No.B of the company \"Fournier and Dixon Ltd.\", changing its name into that of \"R.L.Dixon Ltd.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29196 4291-65 Dynamic Welding Co.Ltd.Notice is given that \"Dynamic Welding Co.Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Vita Fundaro, Secretary.29197-0 3453-65 Jack's Dress Company Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 9,1969, approved the by-law Number 13 of the company \"BoutiqueJMaggie inc.\", changing its name into that of \"Jack's Dress Company\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29198 5202-68 Métro Caravane ltée Metro Caravan Ltd.Notice is given that \"Métro Caravane ltée \u2014 Metro Caravan Ltd.\", has fixed to 4 the number of its directors.Gilbert Currier, Secretary.29201 1687-68 Morgan Insurance Services Ltd.Les Services d'Assurance Morgan ltée Notice is given that \"Morgan Insurance Services Ltd.\u2014 Les Services d'Assurance Morgan ltée\" has changed the number of its directors from 11 to 13.E.W.Rowat, Secretary.29203-o 6379-47 2830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 mai 1969, 101' année, «° 20 Jcan-Pierrc Coiffure inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé le 14 avril 1969 le règlement numéro 3 dc la compagnie * Salon Hans inc.\u2014 Hans Salon Inc.», changeant son nom en celui dc « Jean-Pierre Coiffure inc.».Le sous-ministre des institut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29199-o 5541-64 Lutfy Ltd.Lutfy ltée Le ministre des institutions finuncières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 25 avril 1969 le règlement numéro 53 de la compagnie « Lutfy Whitewear Mfg.Co.», changeant son nom en celui tic « Lutfy Ltd.\u2014 Lutfy ltée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29200-o 3257-45 Montrad Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé lc 17 avril 1969 le règlement numéro A dc lu compagnie « Traders Holdings Ltd.», changeant son nom en celui de « Montrad Ltd.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29202-e 4056-64 Georges Pouliot inc.Avis est donné que la compagnie « Georges Pouliot inc.» a changé le nombre dc ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Georges-A.Pouliot.29204-o 8722-50 Les Presses libres limitée Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé lc 16 avril 1969 lc règlement numéro 4 de la compagnie « Cartomat inc.», changeant son nom en celui de « Les Presses libres limitée ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29205-o 49-08 Salon de Gala Roger Deblois inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé ie 14 avril 1969 le règlement numéro 5 de la compagnie « Salon de Gala inc.», changeant son nom en celui de « Salon de Gala Roger Deblois inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29206-o 4062-68 Traders Holdings Ltd.Avis est donné que la compagnie « Traders Holdings Ltd.» a changé lc nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire-trésorier, E.A.A.Wighton.29207-o 4056-64 Jean-Pierre Coiffure inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 14, 1969, approved the by-law number 3 of the company \"Salon Hans inc.\u2014 Hans Salon Inc.\", changing its name into that of \"Jean-Pierre Coiffure inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29199 5541-64 Lutfy Ltd.Lutfy ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 25, 1969, approved the by-law number 53 of the company \"Lutfy Whitewear Mfg.Co.\", changing its name into that of \"Lutfy Ltd.\u2014 Lutfy ltée\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29200 3257-45 Montrad Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 17,1969, approved the by-law number A of the company \"Traders Holdings Ltd.\", changing its name into that of \"Montrad Ltd.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29202 4056-04 Georges Pouliot inc.Notice is given that \"Georges Pouliot inc.\" changed the number of its directors from 3 to I.29204 Georges-A.Pouliot, Secretary.8722-50 l.cs Presses libres limitée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 16, 1969, approved the by-law Number 4 of the company \"Cartomat inc.\", changing its name into that of \"Les Presses libres limitée\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29205 49-OS Salon de Gala Roger Deblois inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has.on April 14,1969, approved the by-law Number 5 of the company \"Salon de Gala inc.\", changing its name into that of \"Salon dc Gala Roger Deblois inc.\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29206 4062-6S Traders Holdings Ltd.Notice is given that \"Traders Holdings Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 6.E.A.A.Wigiitom, Secretary-Treasurer.29207-o 4056-04 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2831 The United Church Montreal Homes for Elderly People Avis est donné que la corporation « The United Church Montreal Homes for Elderly People » a changé le nombre de ses administrateurs de 22 à 16.Le secrétaire, George \\V.Ham,.2920S 2-65 The United Church Montreal Homes for Elderly People Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 14 avril 1969, approuvé lc règlement Spécial « C » diminuant le nombre des administrateurs de la corporation « The United Church Montreal Homes for Elderly People », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, ' Ls-Philippe Bouchard.29208-o 2-65 Universal Silhouette Ltd.Avis est donné que « Universal Silhouette Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs, de 3 à 4.Le secrétaire, Piiilippo Alfani.29209 12366-60 Zorbas Restaurant Inc.Avis est donné que la compagnie « Zorbas Restaurant Inc.», a changé le nombre de ses administrateurs dc 3 ù 4.Le secrétaire, Georgia Makolakos.29210 4114-68 Bool-in Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 3 avril 1969 le règlement numéro 23 de la compagnie « G.P.Shoemart Inc.», changeant son nom en celui de « Boot - in Ltd.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29238-0 4293-67 Conseil de Bien-Être du Québec Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 24 avril 1969, approuvé les règlements généraux dc la corporation « Conseil de Bien-Etre du Québec», et ce, en vertu de l'article 226 dc la Loi des compagnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29239-0 2006-64 Foyer Lajemmerais Avis est donné que lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a, le 29 avril 1969, approuvé les règlements généraux et le règlement numéro 2 de la corporation « Foyer Lajemmerais », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29243-0 5301-68 The United Church Montreal Homes for Elderly People Notice is given that \"The United Church Montreal Homes for Elderly People\" has changed the number of its directors from 22 to 16.29208-o George W.Hall, Secretary.2-65 The United Church Montreal Homes for Elderly People ' Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives approved on April 14, 1969 Special by-law \"C\" decreasing the number of directors of \"The United Church Montreal Homes for Elderly People\" from 22 to 16, and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29208 2-65 Universal Silhouette Ltd.Notice is given that \"Universal Silhouette Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Philippo Alfani, Secretary.29209-o 12366-60 Zorbas Restaurant Inc.Notice is given that \"Zorbas Restaurant Inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Georgia Manolakos, Secretary.29210-n 4114-08 Boot-in Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 3,1969, approved the by-law number 23 of the company \"G.P.Shoemart Inc.\", changing its name into that of \"Boot-in Ltd.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29238 4293-67 Conseil de Bien-Être du Québec Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 24,1969, approved the general by-laws of \"Conseil de Bien-Etre du Québec\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29239 2006-64 Foyer Lajemmerais Notice is hereby given that the Minister of' Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 29,1969, approved the general by-laws and by-law number 2 of \"Foyer Lajemmerais\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29243 5301-6S 2832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° SO Arthur Deshaics & fils inc.Avis est donné que la compagnie < Arthur Deshaies & fils inc.» a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Marcel Desiiaies.29240-o 2324-03 Dominion Ready Mix Inc.Avis est donné que la compagnie < Dominion Ready Mix Inc.», a changé le nombre dc ses administrateurs de 4 à 0.Le secrétaire, Roland Rochbtte.29241-o 12873-54 Arthur Deshaies & fils inc.Notice is given that \"Arthur Deshaies & fils inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 3.Marcel Desiiaies, Secretary.29240 2324-03 Dominion Ready Mix Inc.Notice is hereby given that \"Dominion Ready Mix Inc.\", has changed the number of its directors from 4 to 6.Roland Rociiette, Secretary.29241 12873-5! The English-Speaking Union of the Commonwealth (Montreal Branch) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives a, lc 28 avril 1969, approuvé lc règlement numéro 4 dc lu corporation \"The English-Speaking Union of the Commonwealth (Montreal Branch) », et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29242-o 798-64 Heather Curling Club Inc.Avis est donné que lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives a, lc 23 avril 1969, approuvé les règlements C et D dc la corporation « Heather Curling Club Inc.», et ce, en vertu dc l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29244-0 2129-22 L'Hôpital Général dc Sorel Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives a, lc 28 avril 1969, approuvé le règlement numéro 2 dc la corporation « L'Hôpital Général dc Sorel », ct ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29245-o 4617-68 Lingerie Lambton inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Lingerie Lambton inc.», a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Florence St-Pierre.29246 2384-64 Km li Montpctit inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 21 avril 1969 le règlement numéro 12 de la compagnie « Roch Montpetit & Perras inc.», changeant son nom en celui dc « Roch Montpetit inc.».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29248-0 11584-54 The English-Speaking Union of the Commonwealth (Montreal Branch) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 28, 1969, approved by-law number 4 of \"The English-Speaking Union of the Commonwealth (Montreal Branch)\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29242 798-64 Heather Curling Club Inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 23, 1969, approved by-laws C and D of \"Heather Curling Club Inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29244 2129-22 L'Hôpital Général dc Sorel Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 28, 1969, approved by-law Number 2 of \"L'Hôpital Général de Sorel\", and such, pursuant to section 225 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29245 4617-OS Lingerie Lambton inc.Notice is given that \"Lingerie Lambton inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Florence St-Pierre, Secretary.29246-0 2384-64 Roch Montpetit inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 21, 1969, approved the by-law Number 12 of the company Roch Montpetit & Pcrras inc.\", changing its name into that of \"Roch Montpetit inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29248 11584-54 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO 2833 Mark Hot inc.Avis est donné que la compagnie « Mark Hot inc.» a changé le nombre dc ses administrateurs dc 7 a 5.Le secrétaire, Charles E.Leoault.29247-0 6729-49 Yvon St-Gelais inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le 17 avril 1969 le règlement numéro XXIV dc la compagnie « Les Entreprises d'Europe (Québec) inc.», changeant son nom en celui dc « Yvon St-Gelais inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29249-0 237-67 S.Storozuk & Son Ltd.S.Storozuk & fils ltée Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis qu'il a approuvé lc 15 avril 1969 lc règlement numéro XXVI de la compagnie « S.Storozuk Transport Ltd.\u2014 S.Storozuk Transport ltée», changeant son nom en celui de « S.Storozuk & Son Ltd.\u2014 S.Storozuk & fils ltée ».Lc sous-minislre des institutions finaiwières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29250-o 5636-65 La Troupe de l'Atelier inc.Avis est donné que lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives a, le 29 avril 1969, approuvé le règlement numéro 1 dc la corporation « La Troupe de l'Atelier inc.», et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29251-0 3944-67 Wcshler Sales Promotions Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie \"Wcshler Sales Promotions Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire-trésorier, Harold Wine.29252 11424-56 Alsco Montreal Inc.Avis est donné que 5 Alsco Montreal Inc.» a changé le nombre de ses administrateurs, de 6 à 8.Le secrétaire, LlLY DUBROFSKY (BeSNEr).29274 13937-51 Mark Hot inc.Notice is hereby given that \"Mark Hot inc.\", has changed the number of its directors from 7 to 5.Charles E.Leqault, Secretary.29247 6729-49 Yvon St-Gelais inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 17, 1969, approved the by-law No.XXIV of the company \"Les Entreprises d'Europe (Québec) inc.\", changing its name into that of \"Yvon St-Gelais inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29249 237-67 S.Storozuk & Son Ltd.S.Storozuk & fils ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 15, 1969, approved the by-law No.XXVI of the company \"S.Storozuk Transport Ltd.\u2014 S.Storozuk Transport ltée\", changing its name into that of \"S.Storozuk & Son Ltd.\u2014 S.Storozuk & fils ltée\".Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29250 5636-65 La Troupe de l'Atelier inc.Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has, on April 29, 1969, approved by-law number 1 of \"La Troupe de l'Atelier inc.\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.29251 3944-67 Weshler Sales Promotions Ltd.Notice is given that \"Weshler Sales Promotions Ltd.\", has changed the number of its directors from 5 to 3.Harold Wine, Secretary-Treasurer.29252-o 11424-56 Alsco Montreal Inc.Notice is given that \"Alsco Montreal Inc.\" has changed the number of its directors from 6 to 8.Lily Dubrofsky (Besner), Secretary.29274-0 13937-51 Rotary Club of Westmount Welfare Fund Rotary Club of Westmount Welfare Fund Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives a, lc 1er mai 1969, approuvé les règlements généraux ur fins d'élection le 1er juin 1909 et pour toutes uulrcs fins lc 1er juillet 1969.Québec, le 6 mai 1969.Le ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal.29264-0 004-02 Val D'Accueil U u plu uu lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1346, en date du 30 avril 1909, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Bonaventure, Suint-Alphonsc-dc-Caplan, Saint-Charles-de-Caplan, Saint-Elzéar ct Saint-Siméon-dc-Bonaventure, dans lc comté dc Bonaventure, ct de l'ériger en une nouvelle municipalité scoluire sous le nom dc Vnl-D'Ac-cucil, dans le comté dc Bonaventure.Le nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé à sept (7).Pour fins d'élection, son territoire est divisé en cinq quartiers, numérotés, représentés et délimités comme suit: Le quartier numéro 1, représenté par un commissaire, comprend le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Saint-Alphonse-dc-Caplan; Le quartier numéro 2, représenté par deux commissaires, comprend le territoire actuel dc lu municipalité scolaire de Saint-Charlcs-dc-Caplan ; Le quartier numéro 8, représenté par un commissaire, comprend le territoire actuel de la municipalité scolaire de Sant-Siméon-dc-Bonavcn-ture; Le quartier numéro 4, représenté par deux commissaires, comprend le territoire actuel de lu municipalité scolaire dc Bonaventure; Le quartier 7iuméro 5, représenté pur un commissaire, comprend le territoire actuel de la municipalité scolaire de Saint-Elzéar.Ces changements prennent effet, pour fins d'élection lc 1er juin 1969 ct pour toutes uutres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 6 mai 1969.Le ministre dc l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.29264-0 004-04 Village de Saint-Germain Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1346, en date du 30 avril 1969, Tracadihche The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1346 dated April 30, 1909, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Carlcton, Maria, Nouvelle and Saint-Omcr, in the county of Bonavcnturc, and to erect it into a new school municipality under the name of Tracadièche, in the county of Bonavcnturc.The number of school commissioners for this new municipality shall be fixed at seven (7).Por election purposes, its territory shall be divided into four wards, numbered, represented and limited as follows: Ward Number 1, represented by two commissioners, covers the present territory of the school municipality of Nouvelle; Ward Number 2, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Omcr; Ward Number 8, represented by two commissioners, covers the present territory of the school municipality of Carlcton; Ward Number 4* represented by two commissioners, covers the present territory of the school municipality of Maria.These changes shall take effect on June 1.1969 for election purposes, and on July 1, 1909 for all other purposes.Québec, May 6.1909.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.29264 004-02 Val D'Accueil The Licutcnunt-Govcrnor has been pleased, by Order in Council No.1340 dated April 30, 1969, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Bonaventurc, Sainl-Alphonse-de-Caplan, Saint-Charles-dc-Caplan, Saint-Elzéar anil Saint-Siméon-dc-Bonaventure, in the county of Bonaventure, nnd to erect it into a new school municipality under the name of Val D'Accueil, in the county of Bonaventure.The number of the school commissioners for the new municipality shall be fixed at seven (7).For election purposes, its territory shall be divided into five wards, numbered, represented nnd limited as follows: Ward number 1, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Suint-Alphonsc-de-Cnplan; Ward number 2, represented by two commissioners, covers the present territory of the school municipality of Saint-Charles-de-Caplan; Ward number 3, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Siméon-de-Bonaventurc; Ward number 4, represented by two commissioners, covers the present territory of the school municipality of Bonavcnturc; Ward number 6, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Elzéar.These changes shall take effect on June I, 1969 for election purposes, and on July 1, 1909 for all other purposes.Québec, May 6, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.29264 004-dl Villuge de Saint-Germain The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1340 dated April 30, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 d'annexer le territoire actuel de la municipalité .scolaire de Saint-Edmond-de-Grantham, dans le comté de Drummond, à la municipalité scolaire du village de Saint-Germain dans le comté de Drummond.Ce changement prend effet, pour fins d'élection, le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 6 mai 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.29264-0 680-01 Chelsea (Prot.) 11 u plu au lieutenant-gouverneur, pur arrêté en conseil No 1427, en date du 7 mai 1909, d'ériger le territoire ci-dessous décrit comprenant celui actuellement sous la juridiction des syndics d'écoles pour la municipalité de Saint-Étienne-dc-Chclsea dans le comté de Gatineau, en une nouvelle municipalité scolaire distincte, pour les protestants seulement, sous le nom dc Chelsea (prot.) dans le comté de Gatineau.Lc territoire de cette nouvelle municipalité scolaire est décrit comme suit, savoir: Cadastre officiel du canton Hull A) I tango VI: Partie du lot 3 située à l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 4 à 12 inclusivement moins toutefois cette partie du lot 7c appartenant à la municipalité scolaire dc Greater Hull (Prot.); Rang VLI : Partie des lots 4 ct 5 située à l'ouest dc la rivière Gatineau ct les lots 6 à 18 inclusivement; Rang VIII: Partie du lot 7 située à l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 8 à 21 inclusivement; Rang IX: Partie des lots 8, 9 ct 10 située à l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 11 à 28 inclusivement; Rang X: Partie du lot 10 situé à l'ouest dc la rivière Gatineau et les lots 11 n 28 inclusivement.Rang XI: Partie des lots 12 ct 13 située ù l'ouest dc la rivière Gatineau et les lots 14 ù 28 inclusivement; Rang XII: Partie du lot 14 située ù l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 15 à 28 inclusivement; Rang XIII: Partie des lots 10 ct 17 située ù l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 18 à 28 inclusivement.Rang XIV: Partie des lots 19 et 20 située à l'ouest de la rivière Gatineau et les lots 21 ù 28 inclusivement; Rang XV: Les lots 216 et 22e-l; Cadastre officiel du canton Eardly B) Rang X: Les lots 1 à 6 inclusivement; Rang XI: Les lots 1 à 10 inclusivement; Rang XH: Les lots 1 ù lia inclusivement.Ce changement prend effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 et pour toutes autres fins le 1er juillet 1969.Québec, le 11 mai 1969.Le ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal.29264-0 970-01 Commission Scolaire Régionale Charlevoix Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1427, en date du 7 mai 1909, d'admettre la commission scolaire de Saint- 2859 1969, to annex the present territory of the school municipality of Saint-Edmond-de-Grantham, in the county of Drummond, to the school municipality of the village of Saint-Germain in the county of Drummond.This change shall take effect on June 1, 1969 for election purposes, and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, May 6, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.29264 680-01 Chelsea (Prot.) The Lieutenant-Governor has been pleased, by Order in Council No.1427 dated May 7, 1969, to erect the hereunder described territory covering that now under the jurisdiction of the school trustees for the municipality of Saint-Êticnnc-de-Chelsea in the county of Gatineau, into a new and distinct school municipality, for Protestants only, under the name of Chelsea (Prot.) in the county of Gatineau.The territory of this new school municipality is described as follows, to wit: Official Cadastre for the township of Hull (A) Range VI: Part of lot 3 situated on the west of the Gatineau River and lots 4 to 12 inclusively, less however that part of lot 7c belonging to the school municipality of Greater Hull (Prot); Range VII : Part of lots 4 and 5 situated on the west of the Gatineau River and lots 6 to 18 inclusively; Range VIII: Part of lot 7 situateil on the west of the Gatineau River and lots 8 to 21 inclusively; Range IX: Part of lots 8, 9 and 10 situated on the west of the Gatineau River and lots 11 to 28 inclusively; Range X: Purl of lot 10 situated on the west of the Gatineau River and lots 11 to 28 inclusively; Range XI: Part of lots 12 and 13 situated on the west of the Gatineau River and lots 14 to 28 inclusively; Range XII: Part of lot 14 situated on the west of the Gatineau River and lots 15 to 28 inclusively; Range XIII: Part of lots 10 and 17 situated on the west of the Gatineau River and lots 18 to 28 inclusively; Range XIV: Part of lots 19 and 20 situated on the west of the Gatineau River and lots 21 to 28 inclusively; Range XV: Lots 216 and 22c-1.Official Cadastre for the township of Eardly (B) Range X: Lots 1 to 6 inclusively; Range XI: Lots 1 to 10 inclusively; Range XII: Lots 1 to 11a inclusively.This chnnge shall take effect on June 1.1969 for election purposes, and on July 1, 1969 for all other purposes.Québec, May 11, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.29264 970-01 Regional School Board of Charlevoix The Lieutenant-Governor bus been pleased, by Order in Council No.1427 dated May 7, 1969, to admit the school commission of Saint- 2860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n\" SO Joscph-de-la-Rive, dans le comté de Charlevoix, comme membre de la Commission Scolaire Régionale Charlevoix.Pour les fins de l'article 480, cette commission scolaire est ajoutée au groupe des délégués des commissions scolaires Lbs Éboulcmcnts et l'Ilc-aux-Coudrcs.Ce changement prend effet le 1er juillet 1969.Québec, lc 11 mai 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.20264-o 085-00 Des Chenaux Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1426 en date du 7 mai 1969, dc fusionner lc territoire actuel des municipalités scolaires dc Sainte-Gcnevicvc-dc-Batiscan, Saint-Luc, Saint-Narcisse, Saint-Prospcr et Saint-Stanislas, dans le comté de Champlain, ct dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom Des Chenaux, dans le comté de Champlain.Pour fins d'élection son territoire est divisé en cinq (5) quartiers, numérotés, représentés ct délimités comme suit, savoir: Le quartier numéro 1, représenté par un commissaire, comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Saintc-Gcncvicve-dc-Batiscan; Le quartier numéro 2, représenté pur un commissaire, comprenant le territoire actuel dc lu municipalité scolaire dc Saint-Luc: Le quartier numéro 3, représenté pur un commissaire, comprenant le territoire actuel dc la municipalité scolaire dc Saint-Narcisse: Le quartier numéro L, représenté par un commissaire, comprenant lc territoire actuel de la municipalité scolaire dc Saint-Prospcr; Le quartier numéro 5, représenté par un commissaire, comprenant le territoire actuel de lu municipalité scolaire dc Saint-Stanislus.Ces changements prennent effet pour fins d'élection, le 1er juin 1969 et pour toutes autres fins lc 1er juillet 1969.Québec, le 11 mai 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.29264-u 770-01 Ville d'East Angus (Cath.) Il a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1426, en date du 7 mai 1969, d'annexer, pour les catholiques seulement, le territoire actuel des municipalités scolaires dc Bury (cath.), Saint-Camille-dc-Cookshire, Saint-Puul-dc-Scotstown (cath.), ct Sawyervillc (cath.), dans lc comté de Compton, ù la municipalité scolaire dc la Ville d'East Angus (cath.), dans le comté dc Compton.Pour fins d'élection, lc territoire annexé est divisé en deux quartiers, numérotés, représentés et délimités comme ci-dessous, ces deux nouveaux quartiers devant s'ajouter aux cinq quartiers déjà existants dans la municipalité scolaire de la ville d'East Angus (cath.) ct portant les numéros de 1 à 5 inclusivement.Le quartier numéro 6, représenté pur un commissaire et comprenant le territoire actuel des municipalités scolaires dc Bury (cath.) et Saint-Puul-de-Scotstown (cath.); Le quartier numéro 7, représenté pur un commissaire et comprenant lc territoire actuel îles municipalités scolaires de Saint-Cumille-de-Cook-shirc (cath.) et Sawyervillc (cath.).Joseph-de-la-Rive, in the county of Charlevoix, as member of the Regional School Board of Charlevoix.For the purposes of section 480, this school commission is added to the group of the delegates of the school commission of Les Eboule-mcnts and l'Ile-aux-Coudres.This change shall take effect on July 1, 1909.Québec, May 11, 1969.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.29264 085-90 Des Chenaux The Lieutenant-Governor has been plcuscd, by Order in Council No.1420 dated May 7.1909, to amalgamate the present territory of the school municipalities of Saintc-Gcncvièvc-dc-Batiscan, Saint-Luc, Saint-Narcisse, Saint-Prosper and Saint-Stanislas, in the county of Champlain, and to erect it into a new school municipality under the name of Des (Chenaux, in the county of Champlain.For election purposes, its territory shall In-divided into five (5) wards, numbered, represented and limited as follows, to wit: Ward number 1, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Sainte-Gcnevièvc-dc-Bntiscan: Ward number 2, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Luc; Ward number 3, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Narcisse; Ward number 4, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Prosper; Ward number 5, represented by one commissioner, covers the present territory of the school municipality of Saint-Stanislas.These chunges shall take effect on June 1, 1909 for election purposes, nnd on July 1, 1909 for all other purposes.Québec, May 11, 1969.Jean-Guy Cardinal.Minister of Education.29264 770-01 Town of East Angus (Cath.) The Lieutenant-Governor has been plcuscd, by Order in Council No.1426 dated May 7, 1969, to annex, for Catholics only, the present territory of the school municipalities of Bury (Cath.), Saint-Camillc-dc-Cookshirc, Snint-Puul-dc-Scotstown (Cath.) and Sawyervillc (Cath.).in the county of Compton, to the school municipality of the town of East Angus (Cath.).in the county of Compton.For election purposes, the unnexed territory shall be divided into two wards, numbered, represented and limited as hereunder, the two new wards to be joined to the other five wards already existing in the school municipality of the town of East Angus (Cath.) and bcuring numbers 1 to 5 inclusively.Ward Number 6, represented by one commissioner nnd covering the present territory of the school municipalities of Bury (Cath.) und Saint-Paul-dc-Scotstown (Cath.); Ward Number 7, represented by one commissioner und covering the present of the school municipalities of Saint-Camillc-dc-Cookshire (Cath.) and Sawyervillc (Cath.). QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 19G9, Vol.101, No.20 2801 Ces changements prennent effet, pour fins d'élection le 1er juin 1969 ct pour toutes autres fins, le 1er juillet 1969.Québec, le 11 mai 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.29264-o 165-00 La Vallibre H a plu au lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil No 1426 en date du 7 mai 1969, de modifier l'item 14 de l'arrêté en conseil No 1056 en date du 2 avril 1969, érigeant la municipalité scolaire de La Vallière dans le comté de Roberval, de la façon suivante: Le sixième ulinéa de l'item 14 dc l'arrêté en conseil No 1056 du 2 avril 1969 est remplacé par les suivants: Lc quartier numéro 3, représenté par trois commissaires, comprend lc territoire actuel de la municipalité de la ville de Saint-Félicien; Le quartier numéro 4, représenté par un commissaire, comprend le territoire actuel de la municipalité dc Saint-Félicien.Québec, le 12 mai 1969.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.29264-0 495-02 Montcalm Il a plu au lieutenant-gouverneur, pur urrêté en conseil No 1427 en date du 7 mai 1909, de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires dc Duberger et Les Saules, «lans lc comté dc Saint-Sauveur, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous lc nom de Montcalm dans le comté de Saint-Sauveur.Lc nombre des commissaires d'écoles pour cette nouvelle municipalité est fixé à neuf (9).Pour les fins d'élection, le territoire dc cette municipalité scolaire est divisé en six quartiers, numérotés, représentés ct délimités comme suit: Le quartier numéro 1, représenté par un commissaire, comprend lc territoire situé à l'intérieur des limites suivantes: La partie de la municipalité scolaire située au sud dc la Rivière Saint-Charles dans les limites de la ville de Duberger.Lc quartier numéro 2, représenté par un commissaire, comprend le territoire situé à l'intérieur îles limites suivantes: La partie de lu municipalité scolaire limitée au sud pur la Rivière Saint-Charles; à l'est par le centre des artères suivantes: Boulevard Central (Nord), Boul.Hamel, rue Labrecque, rue Le-micux, rue Laverdière et Boul.Central (Parc); au nord, par le centre de la rue Nadeau, du Boul.Central (Parc) ù la rue Darveau et par la ligne nord de division des lots 2398-1-44 à 2398-1-40 du cadastre officiel de la paroisse Saint-Sauveur; à l'ouest, par la ligne de division des lots 2397 et 2398 et de son prolongement vers le sud jusqu'à la Rivière Saint-Charles.Lc quartier numéro 3, représenté par un commissaire, comprend le territoire situé à l'intérieur des limites suivantes: La partie de la municipalité scolaire limitée à l'est par le centre du Boulevard Monaco dc la limite nord de la ville de Duberger jusqu'à la rue Cureau, par lc centre de la rue Careau du Boulevard Monaco jusqu'à la ligne de division des lots 2397 et 2398, du cadastre officiel de la paroisse obligations suivantes, émises en vertu du règlement no 289, de la ville dc Québec-Ouest, maintenant ville Vanicr, ont été tirées au sort: Dénominations de $500: 93, 110, 119, 123, 125, 120, 185, 223, 225, 237, 255, 265, 280, 291, 304, 308, 310, 332, 338, 346, 361.377, 379, 413.Dénominations de S100: 10, 51, 52, 66, 113, 145, 164, 167, 186, 188, 190, 195.198, 202, 228, 235, 239, 257, 273, 328, 334, 335, 433, 482, 485, 499, 500, 505, 521, 533, 545, 549, 558.565.I.csilites obligations seront remboursables lc 1er juillet 1969, date ù laquelle elles cesseront de porter intérêt.Québec, le 7 mai 1969.Le secrétaire-trésorier, 29272-0 Roger G au vin.Ville dc Cowansville Conformément aux articles 33 ct 34 de la Loi dc la Société d'habitation du Québec (15-16 Elizabeth II, chapitre 55), avis public est, par les présentes, donné que le conseil municipal dc Cowansville a adopté, lors d'une assemblée spéciale tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le vendredi 9 mai 1969, un programme de rénovation concernant le territoire délimité par: Zone 1.au nord par le boulevard Dieppe, à l'extrême est par la rue .lames, au sud par le C.P.R.et n l'extrême ouest par lu rue Willard; Zone 2.lc lac artificiel, la nie Sanborn, la moitié de la rue Elm, s'étendant aux bâtiments de chaque côté de ces deux rues.Les principaux travaux ù exécuter consistent: 1° Construction «l'une nouvelle rue au nord-est de la zone 1 et à la limite sud dc la même zone, ainsi que deux nouvelles rues dc chaque côté de la rue Sud; 2° ( '(instruction d'habitations subventionnées; 3° Construction de parcs de stationnement dans les deux (2) zones; 4° Amélioration de plusieurs intersections dc rues; 5° Construction «le la rue Sanborn; 6\" Aménagement «le parcs ct «l'une promenade; 7° Aménagement d'un accès et d'un terrain pour fin d'habitation pour les personnes âgées; 8° Fermeture des rues Principale et Caroline; 9° Construction «les égouts collecteurs ct des aqueducs; Ixrs nouvelles réglementations ct modifications aux règlements existants adoptées en vertu de ce programme ct devant entrer en vigueur en vertu de 1 article 41 de la Loi «le la Société (l'habitation du Québec au moment où le territoire «lans lequel elles doivent s'appliquer est décrété « zone dc rénovation », sont les suivantes: 1° Amendement au règlement No 455 concernant l'édification et l'occupation des terrains; 2° Lc code national de bâtiment; 3° Code de logement; The present notice is the second which the undersigned must publish in accordance with paragraph 3 of Section 36 of the City Charter.Robert Bouchard, q.c, City Clerk.City Hall, Montreal, May 17, 1969.27953-7-2-d Town of Vanicr Drawing of bonds (Formerly Town of QuébccAVest) The following bonds, issued under by-law No.289 of the Town of Québec-West, now the Town of Vanicr, have been drawn by lots: Denominations of $600: 93, 110, 119, 123, 125, 126, 185, 223, 225, 237, 255, 265, 280, 291, 304.308, 310, 332, 338, 346, 361, 377, 379, 413.Denominations of-$100: 10, 51, 52, 66, 113.145, 164, 167, 186, 188, 190, 195, 198, 202, 228.235, 239, 257, 273, 328, 334, 335, 433, 482, 485, 499, 500, 505, 521, 533, 545, 549, 558, 565.The said bonds will be redeemable on July I.1969, the date on which they shall wasc to bear interest.Quélwc, May 7.1969.Rooeh Gauvin, 29272 Secretary-Treasurer.Town of Cowansville In conformity with 'articles 33 and 34 of the Québec Housing Corporation Act (15-16 Elizabeth II, chapter 55) public notice is hereby given that the council of Cowansville at a special meeting held in the Town Hall on Friday May 9th, 1969, adopted a renewal program concerning the territory bounded by: Zone 1.Dieppe Boulevard to the north, Jnmes Street to the far east, C.P.R.to the south and by Willard Street to the for west; Zone 2.The artificial lake and Sanborn Street, half of Elm Street extending to buildings on each side of these two streets.The main works to l>e carried out are: 1.Construction of a new street at the northeast of Zone 1 and to the south limit of this same zone as well as two new streets on each side of South street 2.Construction of lodgings for persons of low income; 3.Construction of parking lots in both zones; 4.Improvement of several street comers; 5.Construction of Sanborn Street; 6.Laying out of parks and one promcnude: 7.Laying out of an access road and lot for construction of a home for the aged; 8.Closing down of Main and Caroline Streets; 9.Construction of sewer and water works; The new by-laws and amendments to existing by-laws adopted by virtue of this program and coming into force as provided for by article 41 of the Québec Housing Corporation Act at the time when the territory in which they ure lo apply is declared a \"renewal zone\" arc: 1.Amendments to by-law No.455 concerning construction and occupation of land; 2.The National Building Code; 3.The Housing Code; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.SO 2867 Les intéressés pourront consulter les documents constituant ce programme au 220, Place Municipale, Cowansville, aux heures normales d'ouvcr-Inrc des bureaux; De plus, les intéressés pourront se procurer au même endroit une ou des copies du programme île rénovation au prix unitaire de $25.Kufin, les intéressés peuvent transmettre par écrit leurs objections nu programme ù la Société d'habitation du Québec, 1995 Boulevard Charest, ouest, Sainte-Foy, Québec 10 et ce, pas plus tard (pic le 28e jour de juin 1969.Donné ù Cowansville, ce 9e jour de mai 1969.Le greffier, 29316-0 Jean Leduc.Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec Avis est par les présentes donné que la « Corporation tics Officiers Municipaux Agréés du Québec» a adopté les règlements 11 et 12 |>er-uiettant l'admission de certaines personnes comme membres dc hi corporation ù son assemblée générale annuelle du 9 mai 1969, en vertu de l'article 8 dc la loi constituant la Cor|X>ration des Officiers Municipaux Agrées du Québec, bill ISO, sanctionné le 5 juillet 1968, ct qu'à l'expiration des trente (30) jours suivant la présente publication, lesdits règlements seront soumis [Miiir approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.Règlement numéro 11 IH-rmettant aux assistants ou adjoints des greffiers, trésoriers, secrétaires-trésoriers, gérants, ingéniers ct directeurs de services tel que stipulé aux règlements numéros 2 et 3.Article l Tous les assistants ou adjoints dc greffiers, Irésoriers, secrétaires-trésoriers, gérants, ingénieurs, directeurs de loisirs et directeurs dc services, tel que stipulé uux règlements numéros 2 et 3 dc la Corporation ddes Officiers Municipaux Agréés du Québec, sont admissibles comme membres dc la C.O.M.A.Q.en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi organique de la Corporation (pii stipule: « Pour devenir membre de la Corporation, une personne doit établir, ik la satisfaction du conseil d'administration dc la cori>oration : a) qu'elle est majeure; l>) qu'elle est secrétaire-trésorier, greffier, trésorier ou gérant d'une corporation municipale de cité ou de ville ou qu'elle est un officier municipal dont lu fonction est reconnue par un règlement à cet effet, adopté par la corporation ct approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil; c) qu'elle détient un diplôme d'une université reconnue par lc conseil d'administration; (/) qu'elle a acquitté la cotisation exigible pour l'année en cours; ci qu'elle réside ou travaille habituellement dans le Québec; /) qu'elle remplit toutes les conditions requises par les règlements pour son admission.» Articles lit de plus, elles devront posséder un an d'expérience à l'emploi d'une cité ou d'une ville jugée satisfaisante par le conseil d'administration de lu corporation.The documents forming this program may be consulted by all interested parties at 220 Place Municipale, during the normal business hours.Furthermore, interested persons may obtain at the above address one or several copies of the renewal program for the price of $25 per copy.Finally, those interested may submit in writing to the Québec Housing Corporation at 1995 Charest Boulevard West, Ste-Foy, Québec 10, P.Q.their objections to the renewal program, and this not later that the 28th day of June 1969.Given at Cowansville, this 9th day of May 1969.Jean Leduc, 29316-0 Clerk.Corporation of Chartered Municipal Officers of Québec Notice is hereby given that the \"Corporation of Chartered Municipal Officers of Québec\" has adopted by-laws 11 and 12 permitting the admission of certain persons as members of the corporation at its annual general meeting held on May 9, 1969, pursuant to section 8 of the Act to incorporate the Corporation of Chartered Municipal Officers of Québec, bill 180, assented to on July 5, 1908, and that from and after thirty (30) days following publication of these presents, the said by-laws will be submitted for approval to the Lieutenant-Governor in Council.By-law number 11 permitting assistant or associate clerks, treasurers, secretary-treasurers, managers, engineers and directors of service as stipulated in by-law numbers 2 and 3.Section 1 All assistant or associate clerks, treasurers, secretary-treasurers, managers, engineers, directors of recreation and directors of service, as stipulated in by-laws numbers 2 and 3 of the Corporation of Chartered Municipal Officers of Quel >ec, arc admissible as members of the C.C.M.O.Q.pursuant to the provisions of section 9 of the Act incorporating the Corporation which stipulates: \"To become a member of the Corporation, a person must show to the satisfaction of the board of directors of the Corporation: (a) that he is of the age of majority; (6) that he is a secretary-treasurer, clerk, treasurer or manager of a city or town municipal corporation, or that he is a municipal officer whose office is recognized by a by-law to that effect made by the corporation and approved by the Lieutenant-Governor in Council; (c) that he holds a degree from a university recognized by the board of directors; (rf) that he bus paid the contribution exigible for the current year; (e) that he usually resides or works in the Province of Québec; (J) that he fulfills all the conditions required by the by-laws for his admission.\" Section S And moreover, they must have one-year's experience working for a city or town deemed satisfactory by the board of directors of the Corporation. 2808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 19G9, 101' année, n° 20 Règlement numéro 12 permettant l'admission de certains membres Attendu que le paragraphe « a » de l'article 11 de la loi organique stipule ce qui suit: 11.«Par exception, toute personne qui ne possède pas les exigences académiques prévues au paragraphe « c » de l'article\" 9 mais qui remplit toutes les autres conditions requises par cet article, peut «levenir membre de lu corporation au cours des douze mois qui suivent la sanction de la présente loi, pourvu qu'elle remplisse la condition suivante: A) qu'elle possède cinq (5) années d'expérience pertinente jugée satisfaisante par le conseil d'administration; » À ces causes, il est, pur le présent règlement, statué comme suit : Article 1 Il est référé uu préambule du présent règlement pour valoir comme s'il était ici récité au long.Article 2 Tous les assistants ou adjoints auxquels il est référé ù l'article 1 du règlement numéro 11 peuvent devenir membres de ln cor[>oration aux conditions suivantes: a) qu'ils possèdent cinq (5) années d'expérience pertinente jugée satisfaisante pur le conseil d'administration ; b) qu'ils subissent, avec succès, devant un bureau d'examinateurs nommé ù celte fin par le conseil d'administration, un examen conforme aux exigences dudit conseil; c) qu'ils remplissent les autres conditions mentionnées dans les règlements de la cor|>ora-tion.Copie certifiée des règlements numéros 11 et 12 de la Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec, adoptés par les administrateurs à une assemblée du conseil d'administration tenue le 26e jour d'avril 1969 ct régulièrement approuvés ù l'unanimité le 9 mai 1969, par les membres présents, ù l'assemblée générale annuelle.Signé à Québec, ce 13e jour de mai 1969.By-law number 12 Permitting the admission of certain members Whereas paragraph \"a\" of section 11 of the Act incorporating the Corporation stipulates that: 11.\"However, any person who docs not have the academic requirements contemplated in paragraph \"c\" of section 9 but who fulfills all the other conditions required by the said sections, may become a member of the corporation during the twelve months following the sanctioning of this act, provided that he meet the following condition: (A) that he have five (5) years of pertinent experience deemed satisfactory by the board of directors;\" Therefore, by this by-law, the following is enacted : Section 1 Is referred to the preamble of this by-law and is the equivalent to its repetition here at length.Section 2 All the assistants or associates referred to in section 1 of by-law number 11 may become members of the Corporation on the following conditions: (a) that they have five (5) years of pertinent experience deemed satisfactory by the board of directors; (6) that they submit successfully to an exam which conforms to the requirements of the said board, before a board of examiners appointed for such purpose by the board of directors; (c) that they fulfill the other conditions mentioned in the by-laws of the corporation.Certified copy of by-laws numbers 11 and 12 of the Corporation of Chartered Municipal Officers of Québec, adopted by the directors at a meeting of the board of directors held on the 26th duy of April, 1969, and unanimously approved in the regular manner on May 9, 1909 by the members present at the annual general meeting.Signed at Québec, this 13th day of May, 1909.29330-o Le secrétaire, Jacques Simoneau.29330 Jacques Simoneau, Secretary.Compagnie autorisée à faire des affaires Company Licensed to do Business Eaton Yale & Tow ne Inc.1 Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Eaton Yale & Towne Inc.», a été autorisée ù faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins dc recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est « CT.Corporation System (Canada), Ltd.», de 81, rue St-Picrrc, bureau 42, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la Province est établi à bureau 42, 81, rue St-ierre, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, companies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.29183 23-69 \u2014 1482-50 Eaton Yalc & Towne lue Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Eaton Yale & Towne Inc.\".has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is \"CT.Corporation System (Canada), Ltd.\".-f 81 rue St-Pierre, Room 42, Québec.The principal office of the company in the Province is at Room 42, 81 rue St-Picrre, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institut ions.Companies and Cooperatives.29183-0 23-69\u2014 1482/511 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 19G9, Vol.101, No.20 2869 Association coopérative Cooperative Association Magasin Co-Op L'Unité de la Vernière (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la demande du syndicat coopératif « L'Unité » de cesser d'être régi par la Loi des syndicats coopératifs de Québec, ct de devenir une association régie par la Loi des associations coopératives, sous le nom de « Magasin Co-Op L'Unité de la Vernière ».Québec, le 2 mai 1969.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, 29223-0 Ls-Philippe Bouchard.Magasin Co-Op L'Unité de la Vernière (Cooperative Associations Act) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the request of the cooperative syndicate \"L'Unité\" to cease to be governed by the Québec Cooperative Syndicates Act, and to become an association governed by the Cooperative Associations Act, under the name of \"Magasin Co-Op L'Unité de la Vernière\".Québec, May 2, 1969.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 29223 Companies and Cooperatives.Lettres patentes Marlon's Stores Inc.Dans l'avis de lettres patentes publié dans la Gazette officielle du Québec numéro 19 du 11 mai 1968, nous aurions du lire dans la version française: « Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies » au lieu de «troisième partie de la Loi des compagnies».29267-0 Letters Patent Marlon's Stores Inc.In the notice of letters patent published in the Québec Official Gazetle number 19, dated May 11, 1968, one should have read in the French version: \"Notice is hereby given pursuant to Part I of the Companies Act\" instead of \"Part ILI of the Companies Act\".29267 Demande à la Législature Application to Legislature Ville dc Brassard Avis est par les présentes donné que lu « Ville de Brassard » s'adressera ù la Législature de la Province à sa présente session aux fins d'être autorisée ù détenir, utiliser ou céder à toutes fins quelconques les immeubles acquis pour fins industrielles le 29 décembre 1967, en suite à ses règlements numéros 308 et 316, par acte passé devant Me Jean Boucher, notaire, sous le numéro 8239 dc ses minutes ct enregistré ù La-!miirie sous le numéro 83641; et aux fins de pourvoir au remploi du produit de toute utilisation ou cession.Le procureur de la pétitionnaire, 29343-20-4-o Gaston Pouliot, en.Town of Brassard Public notice is hereby given that the \"Town of Brassard\" will apply to the Legislature of the Province at its present session for the passing of an Act to empower it to hold, use or cede for any purpose whatever, a certain piece of land purchased for industrial purposes on November 29, 1967, in virtue of its by-laws 308 and 316, by deed executed before Jean Boucher, notary, under number 8239 of his munutes and registered at Laprairie under number 83641; and to determine the use that shall be made of the proceeds as the case may be.Gaston Pouliot, q.c, 29343-20-4-o Attorney for Petitioner.Soumissions Cité dc Beaconsfield Comté de Robert Baldwin Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné l'ierre Lcbeau, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 303, Boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, comté de Robert Baldwin, P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 2 juin 1969, pour l'achat de $740,000 d'obligations de la cité de Beaconsfield, comté de Robert Baldwin, datées du 1er juin 1969 et remboursables par séries du 1er juin 1970 au 1er juin 1989 inclusivement, avec intérêt ù un taux non inférieur ù 7%, ni supérieur à S%, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou Tenders City of Beaconsfield County of Robert Baldwin Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Pierre Lcbeau, Secretary-Treasurer, City Hall, 303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield, county of Robert Baldwin, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., Monday, June 2, 1969, for the purchase of an issue of $740,000 of bonds for the city of Beaconsfield, county of Robert Baldwin, dated June 1, 1969, and redeemable serially from June 1, 1970 to June 1, 1989 inclusively, with interest at a rate not less than 7% nor more than 8%, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire 2870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année,'n\" SO des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlements nos: 170 \u2014 $368,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 336 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 342 \u2014 $122,000 \u2014 voirie.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé i\\ compter du 1er juin 1969.Tableau d'amortissement \u2014 $740,000 \u2014 SO ans Annie Capital 1er juin 1970.$17,000 1er juin 1971.18,000 1er juin 1972.18,000 1er juin 1973 .26,000 1er juin 1974 .29,000 1er juin 1975.32,000 1er juin 1976 .34,000 1er juin 1977.38,000 1er juin 1978.43,000 1er juin 1979.49,000 1er juin 1980 .51,000 1er juin 1981.56,000 1er juin 1982.57,000 1er juin 1983.00,000 1er juin 1984 .61,000 1er juin 1985 .26,000 1er juin 1986 .28,000 1er juin 1987 .30,000 1er juin 1988 .33,000 1er juin 1989 .34,000 Dc plus, des soumissions pourront être envoyées ct elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 10 uns ou à courte échéance 15 ans.Également, des soumissions seront reçues et considérées pour des obligu-tions en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans ou en séries 10 ans avec le solde il courte échéance 10 uns pour une partie ct l'autre partie ù terme fixe -20 uns, pourvu toutefois que cette dernière partie ne soit pas pour un montant inférieur à $34,000, et si supérieur ù ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements nnnuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas dc l'exception notée I,'adjudication sera faite conformément il la loi.L'adjudicatuirc s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Beaconsfield.Lc capital et les intérêts sont payables ù toutes les succursales dans la province dc Québec dc la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesditcs obligations ne seront pas rachctables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $34,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $34,000, les obligations ainsi émises seront rachctables par anticipation, au pair, lc 1er juin dc chuque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal ù 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-laws Nos.170 \u2014 $368,000 \u2014 loan renewal: 336 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduct, sewers, and roads; 342 \u2014 $122,000 \u2014 roads.Por adjudication only, interest will be calculated as from June 1,1969.Table of redemption \u2014 $740,000 \u2014 SO years Year Capital June 1, 1970.$17,000 June 1,1971.18,000 June 1.1972.18,000 June 1,1973.26,000 June 1, 1974.29,000 June 1, 1975.32,000 June 1, 1976.34,000 June 1,1977 .38,000 June 1, 1978.43,000 June 1,1979.49,000 June 1, 1980.51,000 June 1, 1981.56,000 June 1, 1982.57,000 June 1, 1983 .60,000 June 1, 1984 .01,000 June 1, 1985 .26,000 June 1, 1986 .28,000 June 1,1987 .30,000 June 1, 1988 .33,000 June 1, 1989 .34,000 Moreover, tenders may be sent and shall be considered for 10-year short-term or 15-year short-term serial bonds.Also, tenders shall be received and considered for 10-year serial bonds with the balance being for 20-yenr fixed-term bonds or 10-year serial bonds with the balance partly for 10-ycar short-term and partly for 20-year fixed-term, provided however, that the latter part be for an amount not less than $34,000.and, if higher than the latter amount, this part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tabic of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Beaconsfield.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term, for an amount equal to $34,000.However, if they are issued partly for 20-year fixed-term for an amount greater than $34,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year, for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1909, Vol.101, No.30 2871 comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 2 juin 1969, ù 8.30 heures du soir, Hôtel de Ville, 303, Boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, comté cut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement No 55-A \u2014 S137.500 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1969.Town of Estércl County of Terrebonne Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Miss Lyse Yergcau, Secretary-Treasurer, Town Hall, Estércl Boulevard, Estérel, county of Terrebonne, P.Q., until 10.30 o'clock, a.m., Monday, June 2, 1969.for the purchase of an issue of $137,500 of bonds for the town of Estérel, county of Terrebonne, dated June I, 1969 und redeemable serially from June I.1970 to June 1, 1979 inclusively, with interest at a rate not less than 7%, nor more than S',, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rutc of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, such as shown on the table of redemption in the present notice.By-law No.55-A \u2014 $137,500 \u2014 renewal of a loan.For adjudication only, interest shall be calculated us from June 1, 1969.Tableau d'amortissement Annie 1er juin 1970.1er juin 1971.1er juin 1972.1er juin 1973.1er juin 1974.1er juin 1975.1er juin 1976.1er juin 1977.1er juin 1978.1er juin 1979.\u2014 $137,500 \u2014 10 ans Capital .$11,500 .12,000 .12,500 .13.000 .13,500 .14,000 .14,500 .15,000 .15,500 .16,000 Table of redemption Year June 1, 1970.June 1, 1971.June 1, 1972.June 1, 1973.June 1, 1974.June 1, 1975.June 1, 1976.June 1, 1977.June 1, 1978.June 1, 1979.\u2014 $137,500 \u2014 10 years Capital .$11,500 .12,000 .12,500 .13,000 .13,500 .14,000 .14,500 .15,000 .15,500 .16.000 On est prié de noter que les soumissions sont Please note that tenders are called for bonds demandées pour tics obligations remboursables redeemable according to the above table only, suivant le tableau ci-dessus seulement, et que and that offers for short-term bonds shall not he les offres qui seront faites pour tics obligations à taken into consideration.Adjudication shall lie courte échéance ne seront pas prises en consitlé- made according to law.ration.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'adjudicataire s'engage ù payer les obliga- The successful tenderer agrees to pay for llic tions capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par bonds, principal and accrued interest, if any, by chèque visé, payable au pair il Stc-Atlèle.certified cheque payable at par at Ste-Adèle. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1909, Vol.101, No.20 2879 Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal ¦le ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation.^ Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, lc 2 juin 1969, a 10.30 heures a.m., Hôtel de ville, boulevard Estérel, Estércl, comté de Terrebonne, i'.q., , ., Le conseil se réserve lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Kstércl (Comté de Terrebonne) ce 8 mai 1969.Le secrélaire-lrésorier, Lvsk Yehoeau.Hôtel dc ville, boulevard Estérel, Estérel, (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 228-2501, code 514.29299-o Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds shall not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, June 2, 1969, at 10.30 o'clock, a.m., at the Town Hall, Estérel Boulevard, Estérel, county of Terrebonne, P.Q.The council docs not bind iLscIf to accept the highest or any of the tenders.' Estérel (County of Terrebonne), May 8, 1909.Lysb Yergeau, Secretary-Treasurer.Town Hall, Estércl Boulevard, Estérel, (Terrebonne), P.Q.Telephone: 228-2501, code 514.29299 Ministère des Affaires municipales ( a 11ai la.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.] ELIZABETH DEUX, pur la grûcc de Dieu, Heine du Royaume-Uni, du Canada ct de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur dc la foi.A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.Lett ris patentes Attendu que l'article 2 dc la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur requête du conseil d'une corporation municipale régie par cette loi, peut émettre des lettres patentes modifiant la charte dc cette corporation, eu y remplaçant certaines dispositions par celles île lu Loi ciled at number 34, on No.154-931.\\ 3rd Street, at Val Saint-Michel, \\ county of Chauveau, versus DAME SIMONE FILTEAU, wife common as to property of Charles Aimé Lagacé, woman engaged in business by assent of the latter personally as well as to authorize his wife to give legal force to procedure, both domiciled at number 139, Saint-Joseph Street, Beauport.Lot 814-5 on the cadastre of Beauport; of an irregular figure, bounded on the northeast by lot 814-6, on the southeast by Rochette Boulevard, on the southwest by lot 815, on the northwest by lot 814 n.s.; measuring eighty feet (80') in width, eighty-two feet and two tenths (82.2') on the southwest, eighty-eight feet (881) on the northeast.Having area of six thousand eight hundred and eight square feet, E.M.Lot 814-6 on the cadastre of Bcauport; of an irregular figure, bounded on the northeast by lot 814-7, on the southeast by Rochette Boulevard, on the southwest by lot 814-5, on the northwest by lot 814 n.s.; measuring eighty feet (80') in width, eighty-eight feet (88') on the southwest, ninety-five feet and eight tenths (95.8') on the northeast.Having an nrea of seven thousand three hundred and fifty-two square feet, E.M.Lot 814-7 on the cadastre of Beauport; of an irregular figure, bounded on the northeast by lot 814 n.s.; on the southeast by Rochette Boulevard, 2886 GAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n\" SO ouest par lc lot 814-6, au nord-ouest par le lot 814 n.s.; mesurant quatre-vingt-dix (90') pieds de largeur, cent treize pieds ct deux dixièmes (113.2') au nord-est, quatre-vingt-quinze pieds ct huit-dixièmes (95.8') au sud-ouest.Contenant en superficie neuf mille quatre cent cinq pieds carrés, m.a.Lot 814-16 du cudastre de Beauport; de figure rectangulaire, borné au nord-est par lc lot 813, au sud-est par lc lot 814-15, au sud-ouest par le lot 814-35 rue, au nord-ouest par lc lot 814-17; mesurant soixante-cinq (65') pieds dc largeur par quntre-vingt-quinze (95') pieds dc profondeur.Contenant en superficie six mille cent soixante-quinze pieds carrés, m.a.Lot 814-17 du cadastre de Beauport; de figure rectangulaire, borné au nord-est par lc lot 813, au sud-est par le lot 814-16, au sud-ouest par les lots 814-35, rue 814-23 rue, au nord-ouest par lc lot 814-18; mesurant soixante-cinq (65') pieds dc largeur par quatre-vingt-quinze (95') pieds tic profondeur.Contenant en superficie six mille cent soixante-quinze pieds carrés, m.a.Lot 814-18 du cadastre dc Bcauport; de figure irrégulière, borné nu nord-est par le lot 813, a usud-est pr le lot 814-17, au sud-ouest par lc lot 814-23 rue, à l'ouest par le lot 814-19; mesurant cent trente (130') pieds au nord-est, quatre-vingt-quinze (95') pieds au sud-est, trente (30') pieds au sud-ouest, cent trente-sept pieds et neuf dixièmes (137.9') à l'ouest.Contenant en superficie sept mille six cents pieds carrés, m.a.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, i\\ Québec, le VINGTIEME jour de JUIN prochain à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 13 mai 1969.29335-0 T E 11 R K B O N N E Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Cour Supérieure, ( JULES DUBOIS, deman-No 761 374.< J deur.vs WILLIAM v KLEIN, domicilié au numéro 5902 de lu rue Westbury, ù Montréal, dans le district dc Montréal, SYLMER INVESTMENT CORP., HELINIA INC., SYLCANNIA INC., MAURISTA INVESTMENT CORP., LEO COLA ROSENBLATT ct SAMUEL CULA ROSENBLATT., tous de Montréal, district de Montréal, défendeurs.L'immeuble ci-après désigné et en In possession des défendeurs ci-haut mentionnés.« Une terre située à Ste-Thérèse île Blainvillc, comté dc Terrebonne, connue ct désignée comme faisant partie du lot numéro quatre-vingt-dix-neuf (ptie 99), aux plan ct livre dc renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse de Blainville, étant plus particulièrement décrite comme suit: partant du point « A » tel que marqué sur lc plan ci-après mentionné, ledit point « A » étant situé à l'intersection du chemin public Grande Côte et de la ligne de division entre le lot cent un ct le lot quatre-vingt-dix-neuf, ct se dirigeant en ligne droite vers le nord-est, sur une distance de 278 pieds, jusqu'au point marqué « B » sur ledit plan ; du point c B » tournant à angle droit ct se dirigeant en ligne droite vers le nord-ouest, sur un» distance de 500 pieds jusqu'à un point marqué « C » sur ledit plan; du point « C » tournant à angle droit et se dirigeant en ligne droite vers le on the southwest by lot 814-6, on the northwest by lot 814 n.s.; measuring ninety feet (90') in width, one hundred and thirteen feet and two tenths (113.2') on the northeast, ninety-five feel and eight tenths (95.8') on the southwest.Having an area of nine thousand four hundred and five square feet, E.M.Lot 814-16 on the cadastre of Beauport; of rectangular figure, bounded on the northeast by lot 813, on the southeast by lot 814-15, on the southwest by lot 814-35 Street, on the northwest by lot 814-17; measuring sixty-five feet (65') in width by ninety-five feet (95') in depth.Having an area of six thousand one hundred and seventy-five square feet, E.M.Lot 814-17 on the cadastre of Beauport; of rectangular figure, bounded on the northeast by lot 813, on the southeast by lot 814-16, on the southwest by lots 814-35, Street 814-23 Street, on the northwest by lot 814-18; measuring sixty-five feet (65') in width by ninety-five feet (95') in depth.Having an area of six thousand one hundred and seventy-five square feet, E.M.Lot 814-18 on the cudastre of Bcauport; of an irregular figure, bounded on the northeast by loi 813, on the southeast by lot 814-17, on the southwest by lot 814-23 Street, on the west by loi 814-19; measuring one hundred and thirty feet (130') on the northeast, ninety-five feet (95') on the southeast, thirty feet (30) on the southwest, one hundred and thirty-seven feet and nine tenths (137.9') on the west.Having an area of seven thousand six hundred square feet, E.M.To be sold at the Québec Registry Office, a I Québec, on the TWENTIETH day of JUNE next, at TEN o'clock in tlic forenoon.Raymond Hains, Sheriff's office.Associate Sheriff.Québec, May 13, 1969.29335 T E R R E B O N N E Canada \u2014 Province of Québec District of Montreal Superior Court, ( JULES DUBOIS, plaintiff.No.761 374.\\ J vs, WILLIAM KLEIN'.' domiciled at number 5902 Westbury St., in Montreal, in the district of Montreal, SYLMER INVESTMENT CORP.HELINIA INC.SYLCANNIA INC., MAURISTA INVESTMENT CORP., LEO CULA ROSENBLATT and SAMUEL CULA ROSENBLATT, all of Montreal, district of Montreal, defendants.The immovable hereinafter designated and in the possession of the above-mentioned defendants: \"A farm situated in Ste-Thérèse de Blainvillc, county of Terrebonne, known and designated as forming part of lot number ninety-nine (P.99).on the official plan and in the book of reference of the parish of Ste-Thérèse de Blainvillc, more fully described as follows: starting at point \"A\" a-marked on the aforementioned plan, said point \"A\" being situated at the intersection of Grandi-Côte public road and the division line between loi one hundred and one and lot ninety-nine, and going in a straight line towards the northeast to a distance of 278 feet to the point marked \"II\" on the said plan; from point \"B\" turning at n right angle and going in a straight line towards the northwest to a distance of 500 feet to a point marked \"C\" on the said plan; from point \"C\" turning at a right angle and going in a straight line towards the northeast to a distance of 225 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2887 nord-est, sur une distance de 225 pieds, jusqu'à un point marqué « D » sur ledit plan; du point « D » tournant à angle droit et se dirigeant en ligne droite vers le sud-est, sur une distance de 500 pieds, jusqu'à un point marqué « E » sur ledit plan; du point * E » tournant à angle droit et se dirigeant en ligne droite, vers le nord-est, sur une distance de 125 pieds, jusqu'à un point marqué « F » sur ledit plan; du point « F » tournant à angle droit et se dirigeant en ligne droite vers le nord-ouest, sur une distance de 0,617 pieds, jusqu'au point marqué « G » sur ledit plan; du point « G » se dirigeant vers le sud-ouest, le long du chemin de la Rivière Cachée, sur une distance d'environ 820 pieds jusqu'à un point marqué « H» sur ledit plan; du point « H » se dirigeant en ligne droite sur une distance de 7,324 pieds jusqu'au point de départ soit le point «A», tel que marqué sur ledit plan.Ladite partie du lot présentement décrite étant bornée comme suit; au sud-est partie par le chemin Grande Côte et partie par partie dudit lot quatre-vingt-dix-neuf, demeurant In propriété du vendeur; en arrière, au nord-ouest, par le chemin Rivière Cachée, d'un côté au nord-est, par partie du lot quatre-vingt-dix-huit (ptie 98) desdits plan et livre de renvoi officiels et d'autre côté, au sud-ouest par partie du lot cent un et partie du lot cent soixante-deux, desdits plan et livre de renvoi officiels.Toutes les mesures ci-dessus sont mesures anglaises plus ou moins.Lc tout ainsi qu'il appert à un plan préparé par M.Harold W.Towle, arpenteur-géomètre en date du dix-sept septembre mil neuf cent cinquante-huit, lequel plan demeure annexé à la présente, après avoir été reconnus véritable pour les parties et signé « ne varietcur » par elles et le notaire soussigné.Tous les droits, titres, prétentions ct intérêts (pic le vendeur a ou peut avoir sur une partie du lot neuf cent cinquante-deux, desdits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Thérèse de Blainvillc, mesurant environ six cents pieds (600') dc longueur sur environ soixante-six pieds (66') de largeur, ct comprise dans les bornes suivantes, savoir: au nord-est par la ligne de division entre les lots quatre-vingt-dix-neuf ct quatre-vingt-dix-huit; au sud-ouest par la ligne de division entre le lot quatre-vingt-dix-neuf et le lot cent un; au sud-est et au nord-ouest par partie dudit lot quatre-vingt-dix-neuf desdits plan ct livre de renvoi officiels.Ainsi que le tout se trouve présentement, avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audits immeubles, et notamment les servitudes en faveur de The Shawinigan Water & Power Co., suivant des actes enregistrés à Terrebonne, sous les nos 107918, 124276, 126230, 172083, 207804, 206210, 123149.L'acquéreur ou ses ayants droit auront droit d'installer un tuyau servant, à égouter le surplus d'eau provenant de l'immeuble présentement vendu, dans le fossé se trouvant dans la ligne est de l'immeuble présentement vendu pour égouter dans la rivière, mais sans aucune responsabilité quelconque de la part du vendeur ct sans causer de dommages à ce dernier.La présente clause créant une servitude en faveur de l'immeuble présentement vendu contre partie dudit lot 99, paroisse Ste-Thérèse de Blainvillc, située au sud du chemin public et demeurant la propriété du vendeur.feet to the point marked \"D\" on the said plan; from point \"D\", turning at a right angle and going in a straight line towards the southeast to a distance of 500 feet to a point marked \"E\" on the said plan; from point \"E\", turning at a right angle and going in a straight line towards the northeast to a distance of 125 feet to a point marked \"F\" on the said plan; from point \"F\", turning at a right angle and going in a straight line towards the northwest to a distance of 6,617 feet, to a point marked \"G\" on the said plan; from point \"G\" going towards the southwest along the Rivière Cachée Road, to an approximate distance of 820 feet to a point marked \"H\" on the said plan; from point \"H\" going in a straight line to a distance of 7,324 feet to the starting point, that is, point \"A\", as marked on the said plan.The suid part of the lot presently described is bounded as follows: on the southeast partly by Grande Côte Road and partly by part of said lot ninety-nine which remains the property of the vendor; in the rear, on the northwest, by Rivière Cachée Road, on one side, on the northeast, by part of lot ninety-eight (P.98) on the said official plan and in the said book of reference, and on the other side, on the southwest, by part of lot one hundred and sixty-two on the said official plan and in the said book of reference.All the above measures arc English measure und approximate.The whole as it np|>cars on a plan drawn up by Mr.Harold W.Towle, land-surveyor, dated the seventeenth day of September, one thousand nine hundred and fifty-eight, which plan remains annexed to the minutes of these presents, after having been recognized n.s true by the parties, and signed \"ne varietcur\" by the same and by the undersigned notary.All the rights, deeds, claims and interests which the vendor has or may have on a part of lot nine hundred and fifty-two, on the said official plan and in the suid book of reference of the parish of Ste-Thérèse de Blainvillc, measuring approximately six hundred feet (600') in length by approximately sixty-six feet (00') in width, and bounded as follows, to wit: on the northeast by the division line between lots ninety-nine and ninety-eight, on the southwest by the division line between lot ninety-nine and one hundred and one, on the southeast and on the northwest by part of said lot ninety-nine on the said official plan and in the said book of reference.The whole as it is presently to be found, with the active and passive servitudes, apparent or unapparcul, attached to the said immovables, and notably the servitudes in favour of \"The Shawinigan Water & Power Co.\", according to deeds registered in Terrebonne under Nos.107918, 124270, 126230, 172083, 207804, 206210, 123149.The purchaser or bis dependents shall have the right to install a pipe to drain the surplus water from the immovable hereby sold into the ditch situated on the east line of the said immovable to drain into the river, but without any responsibility whatsoever on the part of the vendor, and without cuusing any damage to the latter.This clause creates u servitude in favour of the immovuble hereby sold nguinsl part of said lot 99, parish of Sainte-Thérèse de Blainvillc.situated to the south of the public road and remaining the property of tlic vendor. 2888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n° 20 Sauf à déduire les parties dudit immeuble qui ont été expropriées par lc ministère de la Voirie dc la province de Québec, pour les fins de la construction d'un chemin dc raccordement entre la route provinciale No 8 à St-Eustache ct l'autoroute Montréal-Laurcntidc, au chemin de la Côte Cachée à Ste-Thérèse ct qui affecte l'immeuble plus haut décrit en partie de la façon suivante: par une ligne bornée nu nord mesurant 826.60' par le chemin de la Côte Cachée; au nord-est dans une ligne mesurant 1,097.9' par une partie du lot numéro 98; au sud-est, dans une ligne mesurant 592.9' par une partie du lot numéro 99, au sud-ouest par une ligne mesurant 468.65 pieds par une partie du lot No 101, à l'ouest dans une ligne mesurant 456.98'; au sud-ouest dans une ligne mesurant 125'; au sud-ouest dans une nuire ligne mesurant 477.62'; au sud-ouest dans une autre ligne mesurant 127.68; au sud dans une ligne mesurant 130.39'; au sud dans une nutre ligne mesurant 132.52' par une partie du lot No 99, au sud-ouest dans une ligne mesurant 15.4'; par une partie du lot No 101 contenant en superficie 557,458.26 pieds mesure anglaise, soit 15.148 arpents, mesure françnise.Sauf a déduire la partie expropriée par l'office des Autoroutes suivant les enregistrements numéros 297359, 297360, 301309, ct la vente enregistrée sous le numéro 318681 en faveur dc l'Hydro-Québcc: Sujet également ù la servitude de passage accordée ù la corporation dc Ste-Thérèse Ouest par le demandeur suivant l'acte enregistré sous le numéro 291143: Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté dc Terrebonne ù 190 rue Parent, St-Jérômc, MERCREDI, lc DIX-HUITIÈME jour de JUIN mil neuf cent soixnntc-ncuf a DEUX heures dc l'après-midi.Conditions: comptant.Le shérif intérimaire, liurenu du shérif, Gabbibllh Fournelle.St-Jérômc, lc 7 mai 1969.29333-o Save and to be withdrawn arc the parts of the said immovable which were expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec to construct a road linking Provincial Highway No.8 at St-Eustache and the Montrcal-Laurcn-tian Autoroute with Côte Cachée Road ni.Ste-Thérèse and which affects the above-described immovable in part in the following way: by a line bounded on the north, measuring 826.6(1' by Côte Cachée Road, on the northeast, on a line measuring 1,097.9', by a part of lot number 98; on the southeast, on a line measuring 592.9'.by a part of lot 99; on the southwest, by a line measuring 468.65' by a part of lot No.101; on the west, on a line measuring 456.98'; on the southwest on a line measuring 125'; on the southwest, on another line measuring 477.62'; on the southwest, on another line measuring 127.68'; on the south, on a line measuring 130.39'; on the south on unother line measuring 132.52', by a part of lot No.99; on the southwest, on a line measuring 15.4' by a part of lot No.101, having an area of 557,458.26 feet, English measure, that is, 15.148 arpents, French measure.Save ami to be withdrawn is the pari expropriated by the Autoroutes Bureau according to registrations numbers 297359.297360, 301309.and the sale registered under number 318681 in favour of Hydro-Québec.Also subject to the servitude of right of way granted to the corporation of Ste-Thérèse West by the plaintiff according to the deed registered under number 291143.To be sold in the Registry Office of the County of Terrebonne, at 190 Parent St., St-Jérômc.on WEDNESDAY, the EIGHTEENTH day of JUNE, one thousand nine hundred and sixty-nine, at TWO o'clock in the afternoon.Conditions: Cash.Gabkielle Fourneli.k, Sheriff's Office, Interim Sheriff.St-Jérômc, May 7, 1969.29333 INDEX No 20 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 1297 \u2014 Arrimage des chargements de bois de pulpe circulant sur les chemins publics de la province.2848 1297 \u2014 Arrangement of loads of pulpwood on trucks travelling on the Province's public roads.284S 1326 \u2014 Vente du logopède ct dc la perdrix européenne.2847 1326 \u2014 Sale of ptarmigans nnd European partridges.2847 1400 \u2014 Réserve de chasse ct dc pèche dc la Chute Saint-Philippe.281\" 1406 \u2014 Fish and Game Reserve of Chute Saint-Philippe.2847 ASSOCIATION coopérative COOPERATIVE Association Magasin Co-op l'Unité de lu Vernière (eh.).2809 AVIS dhers MISCELLANEOUS Notices Chevaliers de Colomb dc La Tuque, Conseil No 1887 (Bègl.).28W Cowansville, ville-town (Programme de rénoration-RenewalProgram).2S0ii Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec (Règl.U et 12).286i Corporation of Chartered Municipal Officiers of Québec (By-laws 11 and 12).2S0.Knights of Columbus of La Tuque, Council No.1887 (By-laws).286J Montréal, villc-city (Rucs-Riicllcs-Street-Lanes).2861 Northern und Central Gas Corporation Limited (Dem.-Appl.).2863 Vanier, ville-town (Tirage d'obligations-Drawing of Bonds).2S66 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 19G9, Vol.101, No.SO 2889 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME \u2014 Act Abramovici, Lazar (Dem.-Appl.).2844 Albert, Jean-Paul (Dem.-Appl.).2844 Ayotte, Raymond (Dem.-Appl.).2843 Ayoub, Peter (Acc.-Grant.).2844 Dubeau, Nelson Raymond (Dem.-Appl.).2843 Vox, Marcel Robert (Acc.-Grant.).2844 Ivanicr, Paul (Acc.-Grant.).2844 Kosowatsky, Alex (Dem.-Appl.).2845 .Mackenzie, Robert Gordon (Acc.-Grant.).2844 Picard, Marie Jeannine (Acc.-Grant.).2945 Rabinoviteh, Frank (Dem.-Appl.).2843 Rufal, Ella Phyllis Roscngarten (Acc.-Grant.).2845 Rotenstein, Leonard Charles (Dem.-Appl.).2844 Roy, Joseph Charles Anthimc Fernand (Acc.-Grant.).2845 CAISSES SAVINGS d'épargne et dc crédit and credit unions Caisse d'Économie des Employés dc la « Brasserie Dow du Québec » (Québec) (Liquidation).2846 Caisse d'épargne et d'entraide économique de Drummondville (La) (Formation)._.2846 \"Dow Brewery (Québec)\" Employees Credit Union (Québec) (Winding up) 2846 COMPAGNIES Avis relatifs .'i la loi des Autorisée à faire des affaires Eu ton Yale & Town Inc.COMPANIES Notice relative to the Act of Lisensed to do business .2868 2826 2826 i li.ilie-\u2014 Charters \u2014 demandes Application for d'abandon de Surrender of A.N.K.A.Investment Ltd.2822 Andalou Haute Coiffure.2822 Ary Ltd.2823 Autosport ltée.2826 Heaver Development Inc.2823 Boire & Frères inc.2823 Boycr ltée.2826 Brcic (Mario) inc.2826 Canadian Air Pumps Limited.2824 ( 'anadian Stockholders Investment Corporation.?Cic de Gestion Rouberville limitée (La) Club Optimiste St-Adelphc St-Stanislas inc.( 'oi n j lagn ic de Téléphone dc Risborough (La).2826 Daigneault & Frère inc.2824 Domaines du Lac à la Truite inc.2825 l'acclla Investment Co.2824 Golden (J.) Co.2822 (ierson Development Corp.2827 Gordon Manufacturing Co.Ltd.2824 Goyer Avenue Luncheonette Ltd.2827 Great Britain and Canada Investment Corporation.2823 Hôpital Ste-Claire inc.2827 I lurlbut Company Limited.2823 1 niera Construction Ltd.2824 Indépendant Hungarian Protestant Church in Montreal.2825 Léger (O.U.) inc.2823 Manchester Development Ltd.2827 Mister Steers Chuck Wagon Inc.2828 Nutional Intercom Ltd.2827 Philips (George) Corporation.Placements Adjutor Amyot ltée.Poissant limitée.Power-Magic Company Ltd.Robinson (N.) Construction & Equipment Co.Ltd.St.Jovite Realties & Construction Inc.Salon Funéraire La Sarre inc.Servitor Inc.Tiber Investments Limited.Trout Lake Estates Inc 2826 2824 2825 2828 2828 2827 2828 2825 2825 2825 Dissoutes Dissolved A La Gravure inc.2809 Association Professionnelle des Imprimeurs d'Hcbdos du Québec.2809 Canex Realty Limited.2809 Carolou Creations Inc.2809 Centrale Audio-Visuelle inc.(La).2809 Centre Médical de Rouyn inc.2809 Champlain Gas Appliances Inc.2810 Chronique de Magog inc.(La).2810 City Refuse Service Inc.2810 Clinique Linton inc.2810 Cohen (A.) Holdings Inc.2810 Corporation du Cinquantenaire (Amos) inc.2811 Electrical Industries Inc.2811 Elmhurst Dairy Limited.2811 Entreprises Ano ltée (Les).2811 Entreprises Talbot ltée (Les).2811 Établissements Galvanart ltée.2811 Fonds Maskoutains inc.(Les).2812 Galahad Apartments Inc.2812 Hnlpcrn (B.) Investments Ltd.2812 Huron-British Footwear Ltd.2812 Index Secret inc.2812 Joncas Limited.2812 Kaplan (Baris) Inc.2813 Linton Clinic Inc.2810 M an mar Realty Inc.2813 Monart Corporation.2813 Mountain Village Incorporated.2813 Nagley Associates Inc.2813 90 Bates Rond, Ltd.2815 Norris Realties Limited.2813 Pal Construction & Equipment inc- 2814 Peinture Québec inc.(La).-\u2022 \u2022 \u2022 2814 Presses Lithographiques «le Québec inc.(Les).2S14 Quebec Lithographic Press Inc.2814 2890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n\" 20 Dissoutes Dissolved (stiile) (continued) Québec Paint Inc.(The).2814 Rnda Investments Inc.2814 Refugee Aid Society (Montreul Lakcshore) Inc.2814 Rouyn Medical Centre Inc.2809 Shapiro (Eli) Trading Corp.2814 Société d'Aide aux Réfugiés (Bord du Lac Montréal) inc.2814 Service de Rebuts Cité inc.2810 Sollcc Trading Co.2S15 Stotland Holdings Ltd.2815 Tantari inc.2815 Triman Enterprises Ltd.2815 Victor (Jack) Incorporated.2815 Divers Miscellaneous Acme Pontiac-Buick incorporée (Nom- Name ch.).282S Affiliated Factors Corp.(Dir.).2829 Alsco Montreal Inc.(Dir.).2833 Bagel King Inc.(Norn-Name ch.).2835 Bcmal Laboratories Ltd.(Dir.).2829 Boot-in Ltd.(Norn-Name ch.).2S31 Breuvages Crépin inc.(Les) (Nom ch.) 2828 Café Tropicana inc.(Dir.).2834 Conseil dc Bien-Être du Québec (Itègl.- By-laws).2831 Consolidated Plvwood Corporation (Dir.).2829 Crépin Beverages Inc.(The) (Nam» ch.) 2828 Deshaies (Arthur) & fils inc.(Dir.).2832 Développements Parc Québécois inc.(Ix-s) (Dir.).2834 Dixon (R.L.) Ltd.(Nom-Namc ch.).2829 Dominion Ready Mix Inc.(Dir.).2832 Dynamic Welding Co.Ltd.(Dir.).2829 English-Speaking Union of the Commonwealth (Montreal Brunch) (The) (Bcgl.-By-law).2832 Porlin Delage & Associés inc.(Nom-Namc ch.).2835 Foyer Lajemmerais (Bigl.-By-laws)- 2831 Gival inc.(Norn-Name ch.).2834 Heather Curling Club Inc.(Ilègl.-Bylaws) .2832 Ilcrlicon Metals & Plastics Inc.(Dir.) 2834 Hôpital Général dc Sorel (I/) (llcgl.- By-law).2832 .lack's Dress Company (Norn-Name ch.) 2829 Jean-Pierre Coiffure inc.(Norn-Name ch.).2830 Lingerie Lambton inc.(Dir.).2832 Lutfy Ltd.(AW ch.).2830 Lutfy ltée (Nom ch.).2830 M.F.Paint Inc.(Name ch.).2835 Mark Hot inc.(Dir.).2833 Marso inc.(Nom-Namc ch.).2834 Metro Caravan Ltd.(Dir.).2829 Métro Caravane ltée (Dir.).2829 Montpetit (Roch) inc.(Nom-Namc ch.) 2832 Montrad Ltd.(Nom-Namc ch.).- 2830 Morgan Insurance Service Ltd.(Dir.).2829 Paramount Construction (Québec) Ltd.(Dir.).2834 Peintures M.F.inc.(A'oih ch.).2835 Pouliot (Georges) inc.(Dir.).2830 Presses fibres limitée (Les) (Norn-Name ch.).2830 Résidents du Lac des Piles inc.(tas) (Hègl.-By-laws).2834 Rotary Club of Wcstmount Welfare Fund (ltègl.-By-laws).2833 St-Gelais (Yvon) inc.(Nom-Name ch.) 2833 Salon dc Gala Roger Deblois inc.(Nom-Name ch.).2830 Services d'Assurance Morgan liée (Les) (Dir.).2829 Storozuk (S.) & fils ltée (Nom ch.).2833 Storozuk (S.) & Son Ltd.(AW ch.) 2833 Traders Holdings Ltd.(Dir.).2S30 Troupe dc l'Atelier inc.(La) (Bègl.-By-law) .2833 United Church Montreal Homes for Elderly People (The) (Dir.) (Itcgl.- By-laws).2831 Universal Silhouette Ltd.(Dir.).2S3I Urbatique inc.(Nom-Name ch.).283 I Weshler Sales Promotions Ltd.(Dir.).2,s33 Zorbas Restaurant Inc.(Dir.).2831 Lettres patentes tetters Patent Action Photo Service Inc.2772 Aerodoo Holdings Ltd.2772 Aerodoo Montreal Inc.2773 Agenda téléphonique (Montreal) inc.2773 Aidcx Inc.2773 Alaska Properties Inc.2791 Algonquin Publishing Inc.27X6 Ameublement de bureau M.Edery ltée.2774 Amusements Anclo inc.(Les).2771 Anclo Amusements Inc.(Les).2774 Association d'entraide des Amis de St-Ulric inc.(I/).2774 Association Moto-Neige Papiiieuu inc.2775 A.T.C.Corp.2775 Ateliers roulants Bonaventurc ltée (Les) 2775 Buillargcon (A.P.) Location dc camions et remorques inc.2776 Buillargcon (A.F.) Truck & Trailer Rental Inc.2770 Bonavcnturc Shops-on-Whcels Ltd.2775 Boutique Pop' In inc.(La).2i «6 Boutique Wcck-End Inc.2771 Brady (Norman A.), R.Rio|>cllc & Associates Inc.2/ii Brady (Norman A.), R.Riopcllc & associés inc.2777 Brissette (M.) Auto Parts Inc.2777 Bumble Bee inc.'-\u2022,s Campbell (David) & Associates Ltd.2783 Clultcau Bonavista (Québec) Ltd.2778 Clinique de Physiatric dc Laval inc.277S Club dc Hockey National dc Roscmont inc.(Le).2770 Club Le Concorde.2770 Compagnie ( 'anil investissements ltée.2779 Compagnie des Fenêtres du Saguenay inc.(La)-.2780 Comptoir du beigne Jérômien ltée (Le).2i80 ( 'onstruction Des-Cot limitée.2780 Corporation des Marchands dc meubles du Québec (La).2781 Corporation du Cimetière, Catholique de Chicoutimi (La).2816 Côté (Pierre) ltée.2781 Création Loufra inc.(La).278- Darbourg inc.27S2 Dnta Script Inc.27S2 Dave's Transport Inc.27S3 Denis & Robert transport inc.2783 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2891 Lettres patentes Letters Patent (suite) (continued) D.L.M.Holdings Inc.2784 Domar Construction Inc.2784 Dynamic Signs Inc.2784 Dyne Holdings Inc.2785 Échafaudages à érection Rapide ltée.2803 École de conduite Métro inc.2785 Écurie G.L.inc.2785 Edcn Holdings Ltd.2786 Edcry (M.) Office Furniture Ltd.2774 Éditions Algonquin inc.(Les).2786 Entreprises Fero ltée (Les).2786 Entreprises Gay-Net inc.(Les).2787 Entreprises Gerle inc.(Les).2787 Entreprises Reno inc.2787 Entreprises Vimont inc.(Les).2788 Ferronnerie Oxford ltée.2801 Fil Drywall & Painting Inc.2788 G.M.F.& Associates Inc.2789 O.L.Stable Inc.2785 ( i a gnon (Armand) transport téc.2788 ( .iron Hydro-Electric Co.Ltd.2789 Giron Hydro-Électrique Cie tee.2789 G.M.F.& associés inc.2780 Granits de Québec (1969) inc.(Les).2780 Gunter (C.J.) & Sons Ltd.2790 Gycard inc.2790 Habitations Montvillage inc.2791 Hahamovitch Kosher Imports Inc.2791 Holiday Import Corp.2792 Immeubles Alaska inc.2792 Immeubles Rapido ltée.2792 Institut Capillaire de Québec ltée.2792 Institut des relations humaines inc.2793 Institut for Human Relations Inc.2793 Jay Enterprises Ltd.2793 Jeune Chambre de la Rive Sud inc.2794 Journal La Santé inc.2794 Jules rénovation inc.2794 Klub Rustik, inc.2795 Koracn Group Inc.2795 Lachancc (Paul-Eugène) inc.2795 La Haye (Lionel) ltée.2796 Larouche (C.G.L.) ltée.2796 Laurentien Rodco Inc.2796 Léoneuf inc.2797 Lévesque (Albéric) ltée.2797 Lcvisco inc.2797 Lofil inc.2798 Marguerite, corsetière inc.2705 M.D.Q.Investments Ltd.2798 Metro Driving School Inc.2799 Montreuil (Jean Marc) inc.2798 Marton's Stores Inc.(Correction).2869 Moulées Vigor ltée (Les).2808 Nage Corporation.2798 National Tool Hardening Ltd.2799 NatTepperinc.-.2799 Normand (Jacques) inc.2799 - Optilite inc.2800 Ordre Équestre du Saint Sépulcre dc Jé- rusalem-Lieutcnance de Montréal- 2S00 Oxford Hardware Ltd.2801 Petit Séminaire dc Québec (Le).2801 Pierrel inc.2801 Place d'Armes Securities Inc.2808 Plastering (J.J.) Inc.2802 Produits d'emballage & d'imprimerie Rawdon ltée (Les).2S03 Poitras (Yves) inc.2802 Propriétés Triangle limitée (Les).2807 Québec Furniture Retailers Corporation 2781 Québec Hair & Scalp Institute Ltd.2792 Ra-Mon-Ra inc.2802 Randi Mufflers Inc.2802 Rapid Erection Scaffords Ltd.2803 Rawdon Paper Products & Printing L td.2803 Red Star Investments Ltd.2804 Renaud (Arthur) inc.2804 Reno Enterprises Inc.2787 Rodco Laurentien inc.2796 Restaurant Lc Gondolier inc.2804 Rialto Provisions Inc.2805 Sabot inc.(Lc).2805 St-Félicien Jobbing Inc.2805 St.Lambert Printing Service Inc.2806 St.Jerome Donut Shop Ltd.2780 Scwmaco Products Co.Ltd.2806 Société d'Administration immobilière 1 .i ¦ Gardeur inc.(I»a).2806 Toyota Auto Club de Québec inc.2807 Triangle Properties Limited.2807 Usinor limitée.2807 Valeurs Mobilières Place d'Armes inc.280S Vigor Feeds Ltd.2808 Vitrerie Orford inc.2808 Sieges sociaux Head Offices A.& B.System Service Inc.2835 A.& B.Système Service inc.2835 Angel Construction Ltd.2837 Arkitex Inc.2836 Atelier France-Québec inc.2837 Au Carrousel St Jean inc.2837 Cameo Realty Inc.2838 Champoux (Gaston) limitée.2838 Cie de découpoirs en lame d'acier de lu cité inc.2838 City Steel Rule Dies Co.Inc.2838 Club d'Investissement Orford inc.2836 Coastal Shipping Ltd.2839 Composite Development Ltd.2836 ('onstruction Boulevard Léger liée.2835 Construction Norcen inc.2836 Cudex Inc.2836 Drew Brown Shipping and Trading Limited.2839 Entreprises du Nord-Ouest Québécois limitée.2840 Entreprises Napierville inc.(Les).2837 Gauthier (Jean-Paul) inc.2838 Goldmark Optical Supplies Ltd.2840 Gosselin Express Ltd.2838 Gosselin Express ltée.2838 Immeubles Roussin ltée (Les).2837 Magasin 2 pour 1 inc.2840 Messagerie Cotière ltée.2839 Mines Molybia, limitée (I,es).2839 Molybia Mines, Limited.2839 Norcen Construction Inc.2836 North-Wcst Québec Enterprises Limited.2840 Servicentre Hurnois inc.2839 Taverne L'Étricr inc.2839 Textiles Mondor inc.(Les).2837 2 for 1 Storcpnc.2840 2892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 mai 1969, 101' année, n\" 20 DEMANDES APPLICATIONS ii la Législature to Legislature Baldwin-Cartier Shool Commission.2843 Brossard, ville-town.2869 Commission scolaire Baldwin-Cartier 2840 Contrecoeur, c.s.-s.c.2842 Gagnon, ville-town.2843 St-Gabriel, ville-town.2842 Sisters of Charity at Ottawa.2842 Soeurs dc la Charité d'Ottawa (Les).2842 Verdun cité-city.2842 EXAMEN EXAMINATION des Agronomes Agronomists Province, (Pratique-Practice).2840 LIQUIDATION WINDING uvis dc up Notices Caisse d'Economie des Employés dc la * Brasserie Dow du Québec» (Québec).2846 \"Dow Brewery (Quebec)\" Employees Credit Union (Québec).2846 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Outrcmont, cité-city (L.P.) (Mod.- Amend.).2879 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Charlevoix, c.s.r.-r.s.b.(Acc.-Grant.).2859 Berthicr-Dautraie (Acc.-Grant.).2854 Cowansville, (Acc.-Grant.).2855 Chelsea (Prot.) (Acc.-Grant.).2859 Des Cascades (Acc.-Grant.).2855 Des Chenaux (Acc.-Grant.).2860 Harricana (;lcc.-6'ran/.).2855 East Angus, ville-town (Cath.) (Ace,- Grant.).2860 Laurentiennc (Acc.-Grant.).2856 La Vallière (Acc.-Grant.).2861 Levis (Acc.-Grant.).2856 Maniwaki (Acc.-Grant.).2857 Monseigneur Matte (Acc.-Grant.).2857 Montcalm, (Acc.-Grant.).2861 Saint-Germain, village (Acc.-Grant.).2858 Saint-Mathias L-lcc.-Craiif.).2857 Stanstead County (Prot) (Acc.-Grant.).2862 Tracadièche (Acc.-Grant.).2858 Val D'Accueil (Acc.-Grant.).2858 Vaudreuil (Acc.-Grant.).2862 Terres et Forêts Ixtnds and Forests Cadastre: Cadastre: Cadillac, canton-township.2845 Como, village.2845 Lachine, par.2846 St-Ambroisc de la Jeune Lorette, par.2846 NOMINATIONS APPOINTMENTS Divers.2850 President d'élection.2850 Miscellaneous.2850 Returning officer.2850 PROCLAIM ATIONS PROCLAMATIONS Extension de lu juridiction dc lu Cour municipale dc la ville de Delson à lu paroisse dc Saint-Constant, comté dc Laprairic.2853 Extension dc la juridiction de la Cour municipale de la cité dc Drummondville au village de Saint-Germain-dc-Grantham, comté de Drummond- 2852 Extension dc lu juridiction dc la Cour municipale dc la ville «le Terrebonne à la paroisse de Saint-Joachim, comté de L'Assomption.2854 Extension of the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Delson to the parish of Saint-Constant, county of Laprairie.2853 Extension of the jurisdiction to the Municipal Court of the city of Drummondville to the village of Saint-Gcr-muin-dc-Gruntbam, county of Drummond.2854 Extension of the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Terrebonne to the parish of Saint-Joachim, county of L'Assomption.2852 SOUMISSIONS TENDERS Bcaconsficld, cité-city.2860 Berthicrvillc, ville-town.2871 Duberger, ville-town.2870 Estércl, ville-town.2878 Stc-Cécile-dc-Lévrard, pur.2873 St-Eustache, par.2874 SYNDICATS SYNDICATES Professionnels Professional Association des camionneurs urtisans des comtés dc Jean-Talon, Limoilou, Louis-Hébert et St-Sauveur (Nom-Name ch.).2851 Association des enseignants dc Lon-gùeuil-Jacques-Cartier (Nom-Name ch.).2851 Association des responsables de service d'Éducation Phvsiquc du Québec (L') (Const.-Inc.).2851 Syndicat «les détaillants d'essence Sunoco du Québec inc.(Lc) (Const.Inc.) 285(1 Syndicat indépendant des infirmières principales des unités sanitaires dc lu province «le Québec (Lc) (Const-Inc).2851 VENTES SALES SHÉRIFS SHERIFFS Abitibi Abilihi Morissette » Gagnon.2ss0 Itcuucc Beauce Hea u, loi n m Nadeau.2880 Chicoutimi Chicoutimi Central Mortgage and Housing Corporation rs Vaillancourt.2SNl Société centrale d'hypothèques et «le logement vs Vaillancourt.2881 Montréal Montrent Bcrthillier (Bertrand) inc.m Oucllet.2882 Central Mortgage and Housing Corporation va Formcrete Ltd.2883 Central Mortguge and Housing Corporation rs Formcrete Ltd.2883 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 17, 1969, Vol.101, No.20 2893 Montréal Montreal (suite) (continued) Mutual Life Assurance Company of Canada vs Allard.2881 Nantcl et al vs Vcrhelst.2882 Pelletier vs Grand'Maison.2884 Royal Trust Company vs Rainvillc.2884 Société centrale d'hypothèques et de logement M Formcrete.2883 Société centrale d'hypothèques ct de logement vs Formcrete.2883 Québec Québec Huiles Cartier ltée (Les) vs Lamarre.2885 Jenkins vs Dame Simone Filteau.2885 Terrebonne Terrebonne Dubois vs Klein et al.2886 Taxes Taxes Iles de la Madeleine, comté.2816 Magdalen Islands, county.2816 Mégantic, comté-county.2818 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.