Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 3 janvier 1970, samedi 3 (no 1)
[" 102\" ANNÉE VOL.102 $ 3uebec -îUEBEr N» 1 1 fliiÉlfe in Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi .1 janvier 1970 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire ï midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8e Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Sulurday, January 3, 1970 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.0.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.0.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVItE, Québec Officiai Publùher 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n' 1 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligue agate, puni- chaque version, (14 lignes au ]>oucc, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S4 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, S20; du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, S10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lbfebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 Advertising, Kates, Subscriptions, etc.First insertion : 35 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: S4 per 100 words.Single copies: SI cuch.Slips: S3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, S15 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once arc followed by our invoice number.Rocii Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec, April 30.19G9 27440 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif de lu troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-cosh \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes Letters Patent Acro-6 inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de novembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Rolland Dumouchcl, contrôleur, 209, Kerouac, Doris Galarneau, professeur, 475, Dubose, tous deux d'Arvida, et Y von Tremblay, électronicien, 157, Courcelles, Jonquièrc, pour les objets suivants: Exploiter un club d'aviation, sous le nom de « Àéro-6 inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de lu corporation est à Jonquièrc, district judiciaire de Ghicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, LB-PHI lippe Boi'ciiard.3250G-o 5295-09 Acro-6 inc.Notice is given that under Purl III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Rolland Dumouchcl, comptroller, 209 Kerouac*.Doris Galarneau, professor, 475 Dubose, both of Arvida, and Yvon Trembluy, clcctronicinn, 157 Courcelles, Jonquièrc, for the following purposes: To operate a Hying club, under the name of \"Aéro-6 inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is 8100,000.The head office of the cor|>oration is at Jonquièrc, judicial district of Ghicoutimi.Ls-Pniui'i'e Bouchard, Deputy Minister of Financial Inslitutions, Companies and Cooperatives.32506 5295-09 Air-Gcst International Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Moc Ackmun, 26, Aldrcd Crescent, Ilumpsteud, Jack Boidman, 4875, chemin Dufferin, Montréal, et Sidney Cutler, 5767, Glenurdcn, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Air-Gcst International Corp.Notice is given that under Purt I of the Compunies Act, letters patent, bearing date the 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incori>oruting: Moc Ackman, 26 Aldrcd Crescent, Hampstcud, Jack Boidman, 4875 Dufferin Road, Montreal, and Sidney Cutler, 5767 Glenarden, Côte Snint-Luc, all three advocates, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 3 L'industrie et le commerce d'installations et de systèmes d'épuration des eaux, sous le nom de « Air-Gest International Corp.», avec un cupital total de 840,000, divisé en 1,000 uctions ordinaires de SI chacune et 3,900 actions privilégiées de 810 chacune.lration: Paul Bibeuu, vendeur, 9305, rue Lajcunessc, Montréal, Pierre Rodrigue, notaire, 10384, boulevard St-Michel, Montréal-Nord, et Jean-Paul Lord, marchand.550, 10e Avenue, Laval, pour les objets suivants: l'aire le commerce des meubles et nouveautés île toutes sortes, sous le nom de « Les Ameublements Chumplain inc.», avec un capital totul de *30,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de lu compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréul./.(\u2022 snus-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippr Bouciiahd.32506-O 4782-69 Les Ameublements Champlain inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11 th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Bibcau, salesman, 9305, Lajcunessc Street, Montreal, Pierre Rodrigue, notary, 10384 St-Michel Boulevard, Montreal-North, and Jean-Paul Lord, merchant, 550, 10th Avenue, Laval, for the following purposes: To deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Les Ameublements Champlain inc.\", with a total capital stock of $30,000, divided into 300 common shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4782-69 A11 iimnide inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de novembre 1969, constituant en corporation : Danièle Dorget, é|K)use de Philippe Gélinas, 179, chemin Dufferin, M a m pstend.Joseph Vullièrcs, 10585, rue Waver-ley, tous deux avocats, et Dina Robichaud, secrétaire, épouse de Antoine Ordines, 858, rue Mont-Royal est, ces deux derniers de Montréal, |x»iir les objets suivants: Artimonde inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters [latent, bearing dute the 5th day of November, 1969, have liecn issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Danièle Dorget, wife of Philippe Gélinas, 179 Dufferin Road, Hampstcad, Joseph Vallières, 10585 Wovcrlcy Street, both advocates, and Dina Robichaud, secretary, wife of Antoine Ordines, 858, Mont-Royal East Street, the latter two of Montreal, for the following purposes: 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Faire le commerce d'objets, articles, produits d'artisanat et «les marchandises artisunales.ainsi que des travaux d'art de tout genre, tous le nom de « Artimondc inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le snu.i-mini.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32500-o 4798-69 Les As Pce Wee d'Alma inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en tinte du 6e jour de novembre 1969, constituant en cor|ioration sans capital-actions: Jean-Noël Gagnon, professeur, 137, Powell, Normand Drolct, soudeur, 115, Davis, Gaston Lamirande, 615, boulevard Champlain, Roland (îirard, 224, Boulunger, tous deux contremaîtres, et Orner Morais, surveillant, 119, Bcllevue, tous cinq d'Alma, pour les objets suivants: Exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport du hockey, sous le nom de « Les As Pce Wcc d'Alma inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $40,000.Le siège sociul de la coriioration est ù Aima, district judiciaire de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phi lippe Bouchard.32506-o 5327-69 Association Sportive Internationale de l'Amérique du Nord Avis est donné qu'en vertu tic lu troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1969.constituant en corporation sans capital-actions: Carlo Gatti, opérateur, Vittoria Gatti, ménagère, épouse dudit Carlo Gatti, tous deux de 6736, Monk, et Trunzo Bonifazzio, journalier, 6342, Mazarin, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Former et diriger un club sportif, sous le nom de « Association Sportive Internationale de l'Amérique du Nord ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $25,000.I*c siège social de la corporation est 6742, rue Briand, Montréul, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.32506-o 4320-69 Au Réveillon des Gagnon inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date tlu 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Claire Maheux, restaurateur, veuve de Claude Gagnon, rue Notre-Dame, Jacques Duquette, 558, Des Cèdres, et Jacques Perron, 528, Des Cèdres, ces deux derniers avocats, tous trois de Thetford Mines, pour les objets suivants: To deal in wares, articles, handicraft goods, as well as artistic works of all kinds, under the name of \"Artimonde inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district ot Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4798-69 Les As Pec Wcc d'Alma inc.Notice is given that under Purt III of the Companies Act, letters patent, bearing tlate the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, to incorporate a corporation without share capital: Jean-Noël Gagnon, professor, 137 Powell, Normand Drolet, welder, 115 Davis, Gaston Lamirande, 615 Champlain Boulevurd, Roland Girard, 224 Boulanger, both foremen, and Onier Morais, sujicrvisor, 119 Bcllevue, all five of Alma, for the following purposes: To oiicrutc a sports club und to promote hockey in particular, under the name of \"Les As Pec Wee d'Almn inc.\".The amount to which is limited the immovable pro|)crtv which the corporation may ucquirc and possess, is $40,000.The head office of the corporation is at Alma, judicial district of Roberval.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5327-69 Association Sportive Internationale de l'Amérique du Nord Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing tlate the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Carlo Gatti, operator, Vittoria Gutti, housewife, wife of said Curio Gatti, both of 6736 Monk, and Trunzo Bonifazzio, lubourer, 6342 Mazarin.ull three of Montreul, for the following purposes: To form und direct a s|x>rts club, untlcr the name of \"Association Sportive Internationale de l'Amérique du Nord.\" The amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $25,000.The head ollice of the corporation is at 6742 Briand Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilii'pe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4320-69 Au Réveillon des Gagnon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing tlate the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Claire Maheux, restaurateur, widow of Claude Gagnon, Notre-Dame Street, Jacques Duquette, 558 Des Cèdres, and Jacques Perron, 528 Des Cèdres, the latter two advocates, ull three of Thetford Mines, for the following purposes: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.I 6 Exploiter des hôtels, tavernes, auberges, restaurants et maisons de chambres, sous le nom de « Au Réveillon des Gagnon inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 350 actions ordinaires de 8100 chacune et en 50 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Thctford Mines, district judiciaire de Mégantic.Le soun-mi ni.sire des in.il il niions financières, compagnies cl conjurai ices, Ls-I'inui'pk Rouen Ait».3250(3-0 4749-69 To operate hotels, taverns, inns, restaurants and rooming houses, under the name of \"Au Réveillon des Gagnon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 350 common shares of $100 each and 50 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Piiimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4749-69 Autodrome Trois-Rivicrcs liée Avis est donné qu'en vertu tie la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur tic la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour «l'octobre 1969, constituant en corporation : Maurice Rousseau, garagiste, 144, rue Dorion, André .lean, notaire, 424, rue Dumoulin, Mireille Gaudct, secrétaire, épouse de Reginald Ruest, 701a, St-Pierrc, tous trois tie Drummondvillc, et Pernand Aubry, garagiste, 10955, Bois de Boulogne, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des pistes de course d'automobiles, de motocyclettes et d autos-neige, sous le nom de * Autodrome Trois-Rivières ltée », avec un capital total tic 8200,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 17,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Drummondvillc, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouciiahd.32506-o 5034-69 Autodrome Trois-Rivicrcs ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Maurice Rousseau, garage-keeper, 144 Dorion St., André Jean, notary, 424 Dumoulin Street, Mireille Gaudet, secretary, wife of Reginald Ruest, 701a St-Pierre, all three of Drummondvillc, and Pernand Aubry, garage-keeper, 10955 Bois de Boulogne, Montreal, for the following purposes: To operate race tracks for automobiles, motorcycles and snow-mobiles, under the name of \"Autodrome Trois-Rivières ltée», with a total capital stock of $200,000, divided into 3,000 common shares of $10 each und 17,000 preferred shares of $10 each.The heail office of the company is at Drum-mondville, judicial district of Drummond.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5034-69 Bcuucourl pelleteries du Quebec ltée Bcaucotirt Furs of Qui des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Bernard Betty, 2, avenue du l'arc.Clément Carrier, SI, rue Suzor, loua deux courtiers en assurances, d'Arlhabasku, et Jean-Marie Fecuey, notaire, 117, Notre-Dame est, Victoriavillc, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom de « Betty & Currier inc.avec un capital total dc 840,000, divisé en 1.000 actions classe « A » d'une valeur nominale dc SI chacune, 1,000 actions dusse « B» d'une valeur nominale de 81 chacune et en 3S0 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Victoriavillc, district judiciaire d'Arlhubaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopérai ires, Ls-Piiiuppe Bouchard.32506-o 5242-69 Betty & Carrier inc.Notice is given that under l'art I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Bernard Betty, 2 du Parc Avenue, Clément Carrier, 81 Suzor Street, both insurance brokers of Arthnbaska, and Jean-Marie Feency, notary, 117 N'otrc-Damc East, Victoriavillc, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Betty & Carrier inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 class \"A\" shares of a nominal value of SI each, 1,000 class \"B\" shares of a nominal value of SI each and into 380 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Victoriavillc, judicial district of Arthabaska.Ls-Pi 11 i.i ppe Bouchard, Deputy Minisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5242-69 Boules de miel Cainu\\ul inc.Camivul lloncyhulls Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de In province a accordé des lettres patentes, en «laie du 10c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Marvin Biback, 5621, avenue l'aimer.Côte Saint-Luc, Jack l.ightstone, 6S, chemin Stratford, Ilampstcad, Ions deux avocats, et Muriel Fishman, secrétaire, célibataire, 5185.avenue Victoria, Montréal, |Hiur les objets suivants: S'établir restaurateurs, sous le nom dc « Boules de miel Carnaval inc.\u2014 Carnival Honeyballs Inc.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2.0(H) actions privilégiées de 810 chacune Le siège social dc la compagnie est 7275 est, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire «le Montréal./.ur les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « Clinique d'auto Généreux inc.», avec un capital total de $60,000.divisé en 5,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 10,000 actions privilégiées dc 81 chacune.Clinique d'auto Généreux inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Généreux, garage-keeper, 1065 Ladouccur, Jolictte, Robert Machahcc, electrician, 5 Notre-Dame, Léry, and André Perrcault, advocate, 4680 Montcalm, Montreal, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Clinique d'auto Généreux inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 5,000 common shares of 810 euch und 10,000 preferred shares of 81 euch. to GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 Le siège social de la compagnie est 161, Burette, Notre-Dumc-dcs-I'ruiries, district judiciaire de Jolictte.Ije sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5084-69 The head office of the company is at 101 Barrette, Notrc-Damc-des-Prairies, judicial district of Jolictte.Ls-PniLiPPK Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5084-69 Club Aulo-Neige de l'Avenir inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé «les lettres patentes, en date «lu 4c jour dc novembre 1969, constituant en corporation : Louis Lcfarte, gérant dc compagnie dc transport, 764, des Chutes, Denysc Vincent, ménagère, épouse de Henri Lemaire, 16, Begin, et Lucille Pouliot, ménagère, épouse dc Denis Lemaire, 760, des Chutes, tous trois «le Drummondvillc-Sud, pour les objets suivants: Exploiter un club d'auto-ncige, sous le nom dc «Club Auto-Xeigc «le l'Avenir inc.», avec un capital total dc $40,000, eut acquérir et posséder, est de 8500,000.Le siège social dc la corporation est 1080, Côte du Beavcr Hall, Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 2922-69 Les Éditions Commerce Commerce Editions Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Roland-R.Pouliot, chartered accountant, 443 Glengarry, René Provost, 35 Linwood Crescent, both of Mount Royal, Yves Menard, 125 Arlington, Wcstmount, Pierre Shooner, 377 Alexandra, Saint-Lnmbert, and Roger Larosc, 65 Spring Grove Crescent, Outremont, the latter four ad-ninistrators, for the following purposes: To work for the economical, civic and social welfare of Canadians, under the name of \"Les Éditions Commerce \u2014 Commerce Editions\".The amount to which is limited the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is 8500,000.The head office of the corporation is at 1080 Côte du Beaver Hall, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 2922-69 1G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n' 1 Encadrements Select inc.Select Picture Frames Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: J.René Paiement, avocat, 112, 9e rue Roxboro, Cécile Contant, fille majeure, 5060, Pie IX, Montréal, et Lucille Biais, épouse de Jeun-Claude Biais, 24, Gilles, Sainte-Thérèse, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de cadres et moulures, tableaux et objets d'art, sous le nom de « Encadrements Select inc.\u2014 Select Picture Frames Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège sociul de la compagnie est 4555, rue Jeanne d'Arc, Montréal, district judiciaire dc Montrent Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 4932-69 Encadrements Select inc.Select Picture Frames Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: J.-René Paiement, advocate, 112, 9th St., Roxboro, Cécile Contant, spinster of the full age of majority, 5060 Pie IX, Montreal, and Lucille Biais, Wife of Jean-Claude Biais, 24 Gilles, Sainte-Thérèse, the latter two secretaries, for the following purposes: To manufacture and deal in frames and mouldings, paintings and works of art, under the name of \"Encadrements Select inc.\u2014 Select Picture Frames Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $10 each and 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 euch.The head office of the company is at 4555 Jeanne d'Arc St., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4932-69 Les Entrepreneurs I.C.M.ltée I.C.M.Contractors Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc lu première purtic dc lu Loi des compugnics, le licutennnt-gouverneur de la province a uccordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Michel Robert, 500, Abélard, Verdun, Lucien Dansercau, 4977, Jean Brillant, et Michel Proulx, 4290, Kindersley, ces deux derniers de Montréal, tous trois avocats, I>our les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce dc toutes sortes d'appareils ou systèmes de chauffage, sous le nom «le « Les Entrepreneurs I.C.M.ltée \u2014I.C.M.Contractors Ltd.», avec un capital total «le $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 515, Ste-Catherine ouest, suite 414, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouciiahd.32506-o 4913-69 Ia'h Entrepreneurs I.C.M.liée I.C.M.Contractors Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Robert, 500 Abélard, Verdun, Lucien Dansercau, 4977 Jean Brillant, and Michel Proulx, 4290 Kindersley, the latter two of Montreal, ull three advocates, for the following purposes: To curry on business us builders und gencrul building contractors and to deal in all kinds of apparatus or heating systems, under the name of \"Les Entrepreneurs I.C.M.ltée \u2014 I.C.M.Contractors Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 390 preferred shares of 8100 each.The head office of the compuny is nt 515 Stc-Catherine West, suite 414, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4913-69 Les Entreprises André Lambert inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a uccordé des lettres patentes, en date «lu 30e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: André Couture, 50, rue Speid, Lennoxville, Armand Bolduc, 380, Châtelaine, tous deux notaires, et Lise Drouin, secrétaire, épouse de Marc-André Paquette, 1281, Dorval, ces deux derniers de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les Entreprises André Lambert inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Les Entreprises André Lambert ine.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, tearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: An«lré Couture, 50 Speid Street, Lennoxville, Armand Bolduc, 380 Châtelaine, both notaries, and Lise Drouin, secretary, wife of Marc-André Paquette, 1281 Dorval, the latter two of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les Entreprises André Lambert inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 17 Le siège social de la compagnie est à Ascot-Nord, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4240-6!) I,es Entreprises Capricorne limitée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Daniel Kingstonc, 4985, Iona, Montréal, Irving L.Adessky, 56, Heath Place, Hampstead, et Dionysia Zcrbisias, 5525, Westbourne, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Diriger une compagnie de portefeuille, dc recherche et dc construction, sous le nom dc « Les Entreprises Capricorne limitée», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.l*c siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.32500 5069-69 Les Entreprises JEM inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Jean-Marie Mathieu, commerçant, Clairette Piché, ménagère, épouse dudit Jean-Marie Mathieu, tous deux de 27, rue Du Parc, et Bertrand Lamothe, avocat, S05, rue ( urdinal-Roy, tous trois dc Cup-de-la-Mndeleine, pour les objets suivants: Exploiter une tabagie, sous le nom dc « Les Entreprises JEM inc.», avec un capital total de 810,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de SHK) chacune.Le siège social de la compagnie est 608, rue Thibeau, Cap-dc-la-Madcleine, district judiciaire dc Trois-Rivières.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.325004 4976-69 Les Entreprises Lajcunessc inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u uccordé des lettres patentes, en date du 31e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Joseph P.Miller, 120, 90e avenue.Lu Salle, Isidore Buller, 8530.' 'liumpugneur, tous deux avocats, et Barry Fish, étudiant, 3420, Ellendule, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immeubles, de construction et dc placements, sous le nom de « Les Entreprises Lajcunessc inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 2,000 aetions ordinaires de $10 chacune et 1,800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 9310, 1.a jeunesse, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5299-69 The head olfice of the company is at Ascol-Xorth, judicial district of Saint-François.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4240-69 Les Entreprises Capricorne limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Daniel Kingstonc, 4935 Iona, Montreal, Irving L.Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, and Dionysia Zerbisias, 5525 West-bourne, Côte Saint-Luc, ull three advocutes, for the following purposes: To carry on the business of a holding, research und building company, under the name of \"Les Entreprises Capricorne limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head olfice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5069-69 Les Entreprises JEM inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenunt-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marie Mathieu, trader, Clairette Piché, housewife, wife of said Jean-Muric Mathieu, both of 27 Du Park Street, und llertrund Lamothe, advocate, 805 Cardinal-Roy Street, all three of Cap-dc-la-Madeleinc, for the following purposes: To operate a tobacco store, under the name of \"Les Entreprises JEM inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The heud office of the company is ut 608 Thibenu Street, Cup-de-ln-Madeleinc, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial InstitiUions, Companies and Cooperatives.32506 4976-69 Les Entreprises Lajcunessc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Joseph P.Miller, 120, 90th Avenue, LaSallc, Isidore Buller, 8530 Champugneur, both udvocutes, und Burry Fish, student, 3420 Ellen-dale, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the numc of \"Les Entreprises Lujeuncssc inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 1,800 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9310 Lajeunesse, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5299-69 IS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S janvier 1970, 102' année, »\u2022 / Les Entreprises Laucof inc.Laucof Enterprises Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-Paul Lauzier, fonctionnaire, Claire Cofsky, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Lauzier, tous deux de route 17, Vaudrcuil, et Michel Lauzier, fonctionnaire, 4230, St-André, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des motels, hôtels, tavernes, auberges, restaurants et magasins, sous le nom dc « Les Entreprises Laucof inc.\u2014 Laucof Enterprises Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 500 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social «le la compagnie est roule 17, Vaudrcuil, district judiciaire de Montréal.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et eoopêratires, Ls-PlIII.IPPK bouchard.32506-o 4699-69 Les Entreprises Laucof inc.Laucof Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Paul Lauzier, civil servant, Claire Cofsky, housewife, wife of the said .lean-Paul Lauzier, both of Route 17, Vaudrcuil, and Michel Lauzier, civil servant, 4230 St-André, Montreal, for the following purposes: To operate motels, hotels, taverns, inns, restaurants and stores, under the name of \"Les Entreprises Laucof inc.\u2014 Laucof Enterprises Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The heud office of the company is at Route 17, Vaudrcuil, judicial district of Montreal.Ls-PulLIPPE bouchard, Dcputji Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4699-69 Les Entreprises L, P.Brosseau ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur tic lu province a uccordé des lettres patentes, en dutc du 8e jour d'octobre 1969, const il uant en corporation : Louis Philippe Bros-seuu, industriel, Carmen Brossenu, ménagère, épouse dudit Louis Philippe Brosseuu, tous deux de 7600, D'Aubigny, Anjou, et Réul Dion, avocat, 15, Lévesque, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous le nom de « Les Entreprises L.P.Brosseau ltée », avec un capital total de S40.000, divisé en 400 actions ordinaires dc $1 chacune et en 3,960 actions privilégiées tic S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 7600, D'Aubigny.Anjou, tlistrict judiciaire de Montréal.lœ sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phimppk Bouciiahd.32506-o 4709-69 Les Entreprises L.P.Brosseau liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis Philippe Brosseau, industrialist.Carmen Brosseau, housewife, wife of the said Louis Philippe Brosseau, both of 7600 D'Aubigny, Anjou, and Real Dion, advocate, 15 Lévesque, Laval, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Entreprises L.P.Brosseau ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $1 each ami 3,960 preferred shares of $10 euch.The head oflicc of the company is at 7600 D'Aubigny, Anjou, judicial district of Montreal.Ls-PmuppE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4709-69 Les Entreprises Verdi inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie tic lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date tlu 27c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Olivier Gauthier, avocat, 8400, St-Laurent, suite 206, Emile Berardinucci, homme d'affaires, 6608, Papincau, tous deux de Montréal, et Nicole Gagnon, secrétaire, fille majeure, 1985, Paradis, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie tic portefeuille (holding), sous le nom de « Les Entreprises Verdi inc.», avec un capital total «le $100,000, divisé en 7,000 actions ordinaires tie $10 chacune et en 300 uctions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal-Nord, district judiciaire dc Montréal.lx sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippk Bouchard.32506-o 5189-69 Les Entreprises Verdi inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters potent, bearing dutc the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Olivier Gauthier, advocate, 8400 St-I.an rent, suite 206, Emile Berardinucci, businessman, 6608 Papincau, both of Montreal, and Nicole Gagnon, secretary, spinster of the full age of majority, 1985 Paradis, Laval, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Les Entreprises Verdi inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 7,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The heud oflicc of the compuny is at Montreal-North, judicial tlistrict of Montreal.Ls-Puilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5189-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, JÛ70, Vol.102, No.1 lit Ix-s Équipements de Rembourrage Jolibois inc.Jolibois Upholstering Equipment Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la premiere partie dc lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Maurice Jolibois, marchand, SI, Lnbbé, Pierre Bélivcuu, commis, 112, Alice, tous deux de Victoriavillc, et Louise Leclcrc, secrétaire, fille majeure, 2, Bcllcuu, Arthabaska, pour les objets suivants: Faire affaires comme rembourreurs, sous le nom de « Les Équipements de Rembourrage Jolibois inc.\u2014 Jolibois Upholstering Equipment Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Victoria-ville, district judiciaire d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5163-69 Ferme du Rossignol inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc lu province a accordé des lettres patentes, en date du 2Sc jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Laurent Côté, aviculteur, Jeanninc Miction, ménagère, épouse dudit Laurent Côté, et Daniel Michon, cultivateur, tous trois dc La Présentation, jx)iir les objets suivants: Exploiter une entreprise agricole d'élevage d'animaux de toutes sortes, sous le nom de « Ferme du Rossignol inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.I* siège social de la compagnie est à La Présentation, district judiciaire dc Saint-Hyacinthe./.cratc an hospital, under the mime of \"Grace Dart Hospital Foundation\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 23 Le montant auquel se limite le revenu annuel sur les biens immobiliers que la corporation peut détenir ou posséder est dc $50,000.Le siège social de la corporation est 6085 est, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5041-69 Ilargrcaves Estate Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 30c jour d'octobre 1969.constituant en corporation: Wesley Hyndman Bradley, avocat, Margaret .loyce Bradley, commis, célibataire, et Claire Descoeurs, secrétaire, veuve de J.-P.Dcscociirs, tous trois du 360 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une société d'immeuble et de placement, sous le nom de « Ilargrcaves Estate Inc.».avec un capital total de $700,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 8100 chacune et 5.000 actions privilégiées «l'une valeur au pair de 8100 chacune.ta siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire «le Montréal, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalircs, Ls-PlIlI.IPPK BoÛCIIARD, 32506 4349-69 The amount to which the annual revenue from the immoveable property which the corporation may hold or possess is to be limited, is 850,030.The head ollice of the corporation is at 0085 Sherbrooke Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5041-09 Ilargrcaves Estate Inc.Notice is given that under l'art 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Wesley Ilyudman Bradley, advocate, Margaret Joyce Bradley, clerk, spinster, and Claire Drscoeurs, secretary, widow of J.-P.Descoeurs, all three of 360 St.James Street West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and investment company, under the name of \"Ilargrcaves Estate Inc.\", with a total capital stock of $700,000, divided into 2.000 common shares of a par value of 8100 each and 5,000 preferred slum's of a par value of 8100 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiimppe Bouchard, Deputy M inisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3250(i-o 4349-69 I bin-it Ajustement (Jolictte) inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Robert Thériault, agent dc réclamations, Jeannine Paquet, ménagère, épouse dudit Robert Thériault, tous deux île 1435, rue Perrcault, et Georges Roy, agent-vendeur.456.nie Précieux-Sang, tous trois de \u2022lolictte, |M)iir les objets suivants: Enquêter sur un sinistre, un accident, évoluer les pertes, estimer les dommages en découlant on négocier le règlement de la réclamation en résultant, sous le nom de « Hébert Ajustement (Jojiette) inc.», avec un capital total dc 840.000.divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale «le 810 chacune.ta siège social «le la compagnie est à Jolictte.district judiciaire de Jolictte.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piin.ii'i'K Bouciiahd.32506-o ' 4821-69 Hébert Ajustement (Jolictte) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 41 h day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Thériault, claim ajusl-inent agent.Jeannine Paquet, housewife, wife of said Robert Thériault, both of 1435 Perrcault Street, and Georges Roy, sales agent, 456 Précieux-Sang Street, all three of Jolictte, f«>r the following purposes: To investigate disasters.iiccidcnLs; to evaluate losses and estimate damages deriving therefrom or to negotiate the settlement of claims, under the name of \"Hébert Ajustement (Jolictte) inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of 81 each and 3,500 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head ollice of the company is at Jolictte, judicial district of Jolictte.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4821-69 Hôpital de Langetiii Avis est donné qu'en vertu dc lu troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accortlé des lettres patentes, en dutc du 22c jour d'octobre 1969, constituant en corporation suns capital-actions: \u2022l.-Yvcs Larochellc, médecin, Gco.-Octavc Lan-glois, notaire, et Ls-Philippe Lessard, courtier en assurance, tous trois dc Sainte-Justine, pour les objets suivants: Administrer un hôpital, sous le nom dc < Hôpital de Lange vin ».Hôpital de Lungevin Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent.bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: J.-Yves Larochelle, physician, Geo.-Octave Lan-glois, notary, and Ls-Philippe Lessard, insurance broker, nil three of Sainte-Justine, for the following purposes: To administer u hospilul, under the name of \"Hôpital de Langevin\". 21 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" I Le montant auquel est limitée la valeur des liicns immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc S2,000,000.Le siège social de la corporation est à Sainte-Justine, tlistrict judiciaire dc Bcnucc.Le sous-ministre des inslilnlions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4428-69 The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire an d hold is to be limited, is $2,000,000.The head office of the corporation is at Sainte-Justine, judicial district of Benucc.Ls-Phimppk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.12506 4428-69 Hôpital Saint-PauI-dc-Montminy Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour dc novembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Paul Wagner, médecin, Noëlln Coulombe, infirmière, épouse dc Pnul-Omcr Biais, Leopold Chambcrland, bijoutier.Treille Talbot, cultivateur, J.-Maurice Cloutier, notaire, Paul-Aimé Lafcrrièrc, instituteur, Monique (ingnon, ménagère, épouse dc Rémi Biais, tous sept de Saint-Paiil-de-Montminy, Real Gaiidmiu, marchand, Notrc-Damc-du-Rosnirc, et Marins Brisson, cultivateur, Saint-Fabien-dc-Panct, pour les objets suivants: Administrer un hôpital, sous le nom de « Hôpital Saint-Paul-de-Montminy ».Le montant auquel est limitée In valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder lu corporation, est dc $2,000,000.Le siège social de la corporation est à Saint-Paul-dc-Montminy, district judiciaire de Montmugny.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phimppk Bouciiahd.32506-u 5306-69 Hôtel Brunswick inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Paul l'iliaull, entrepreneur, S.Tobin, Bromptonville, Etienne Sl-Ongc, hôtelier, 806, Principale nord, Richmond, cl Maurice Busqué, comptable, 1141, Conseil.Sherbrooke, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, motels, tavernes, auberges cl restaurants, sous le nom de « Hôtel Brunswick inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune cl en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Richmond, district judiciaire de Saint-François.Le sous-mi n islre des inslilnlions financières.compagnies et cooperalircs, Ls-Piiiuppe IJouciiard.32506-u 516S-69 Hôpital Saint-Paul-de-Montminy Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jean-Paul Wagner, doctor, Noclla Coulombe, nurse, wife of Pnul-Omer Biais, Leopold Chamberlain!, jeweller, Trefflé Talbot, farmer, J.-Maurice Cloutier, notary, Paul-Aimé Lafcrrièrc.professor, Monique Gugnon, housewife, wife of Rémi Biais, ull seven of Suint-PauI-de-Mont-miny, Real Gaudreau, trader, Notrc-Dumc-du-Rosairc, and Marins Brisson, farmer, Snint-Fabicn-dc-Pnnct, for the following purposes: To direct n hospital, under the name of \"Hôpital Saint-Paul-de-Montminy\".The amount to which is limited the value of the immovable pro|>crty which the corporation may acquire and possess, is $2,000,000.The head ollice of the corporation is at Saint-Paul-dc-Montniiny, judicial districl of Montmugny.Ls-Piiimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.32506 5306-69 Hôtel Brunswick inc.Notice is given that under Part I of the Compunics Act, letters patent, bearing date the 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul Filiault.contractor, 8 Tobin.Bromptonville, Etienne St-Onge, hotel-keeper.806 Main St.north, Richmond, ami Maurice Busqué, accountant, 1141 Conseil, Sherbrooke, for the following purposes: To operate hotels, motels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Hôtel Brunswick inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of $10 each ami 2,000 preferred shares of S10 each.The head ollice of the company is al Richmond, judicial district of Saint-François.Ls-Piiiuppe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial I list il niions.Companies and Cooperalircs.3250(i 5I6S-69 Hôtel-Dieu dc St-Pamphilc Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province n uccordé des lettres patentes, en dutc du 22c jour d'octobre 1969, constituunt en corporation suns cnpitul-actions: Louis-Félix Curon.Laurent Anctil, tous deux industriels.Clan le Dupont, Joscph-Amuble Pelletier.Valèrc Dupont, tous trois cultivuteurs, ftlisé Vuillancourt, commis-comptable, Jocelyn Mignault, médecin, tous sept île Saiiit-Pamphile, Sylvio Blanchct, commerçant, Sainl-Adalbert, Benoit Blanchct, ouvrier, Saint-Omer, Léo Ga- Hôtcl-Dieu de Sl-Pamphile Notice is given that under Purl III of the Companies Act, letters patent, bcuring date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a cor|K»ration without share capital: Louis-Félix Caron, Laurent Anctil, both industrialists, Claude Dupont, Joseph-Amablc Pelletier, Valèrc Dupont, all three farmers, blisc Vaillancourt, clerk-accountant, Jocelyn Mignuult.doctor, ull seven of Saint-l'umphilc, Sylvio Blau-chet, trader, Snint-Alulberl, Benoit Blunchel.labourer, Saint-Omer, Léo Gugnon, trader, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 25 gnon, commerçant, Sainte-Pcrpctuc, et Joseph Dumont, commis-comptable, Tourville, pour les objets suivants: Administrer un hôpital, sous le nom de « Hôtel-Dieu de St-Pamphile ».Ia?montant uuquel est limitée la valeur des biens immobiliers (pic peut acquérir et posséder la corporation, est de §2,000,000.1a: siège social dc la corporation est à Saint-Pamphilc, district judiciaire dc Montmugny.Le sous-ni in i«Ire des institutions financières, compagnies et coopérai ires, Ls-Philippe Bouchard.12506-0 1452-0!) Suintc-Perpétue.and Joseph Dumont, clerk-uccounlunt, Tourville, for the following purposes: To direct a hospital, under the nume of \"Hôtel-Dieu de St-Pamphile\".The amount to which is limited the value of the immovable properly which the corporation may acquire and possess, is $2,000,000.The head ollice of the corporation is at Suint-Pamphilc, judicial district of .Montmugny.Ls-Pn i i.i ppe Dor eu Ait n.Deputy Minister of Financial Inst il niions.Companies and Cooperatives.52506 1452-6!) Hôtel Gaspé inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première pnrtic dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de novembre 1960, constituant en corporation: Gilles Dubois, représentant, Fleur-Ange Lemire, ménagère, épouse dudit Gilles Dubois, tous deux de 4465, Jacques-Cartier, Douville, Roger Loisellc, gérant d'hôtel, et Jacqueline Suvurd, ménagère, épouse dudit Roger Loisellc, ces deux derniers de 145, boulevard Cartier, Deloeil, pour les objets suivants: Exploiter «les hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom dc « Hôtel Gaspé inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 373, rue dc Gaspé, Asbestos, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5607-69 Puul Houle inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en «latc du 3c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Henri-Paul Lemay, 426, Champagncur, Outremont, Maurice Paquin, 467, Radisson, Saint-Hilaire, et Murio-R.Girard, 4S58, Côte des Neiges, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'informatique, sous le nom de « Paul Houle inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 3,900 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Douchard.32506-o 5321-69 Hôtel Gaspé inc.Notice is given that under Part I of the 'Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Dubois, representative, Fleur-Angc Lemire, housewife, wife of said Gilles Dubois, both of 4465 Jacques-Cartier, Douvillc, Roger Loisellc, hotel manager, and Jacqueline Savard, housewife, wife of said Roger Loisellc, the latter two of 145 Cartier Boulevard, Dclocil, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Hôtel Gaspé inc.\", with u totul cnpital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 euch und into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 373 dc Gaspé Street, Asbestos, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.32506 5607-6!) Puul Houle inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Henri-Paul Lemay, 426 Champagncur, Outremont, Maurice Paquin, 467 Radisson, Saint-Hilairc, and Mario-R.Girard, 4858 Côte des Neiges, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To curry on business as a data processing company, under the name of \"Paul Houle inc.\", with a totul cnpital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $1 each und into 3,900 preferred shares of a nominal value of $10 euch.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5321-69 lie Pcrrot Auto Parts Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour dc novembre 1969, constituant en corporal ion : Gaétan Pilon, marchand, Claudette C.Pilon, ménagère, épouse dudit Gaétan Pilon, et Jean-Marc Sureau, marchand, tous trois de Saint-Clet, pour les objets suivants: Ile Perrot Auto Parts Inc.Notice is given that under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing dute the 5th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gaétan Pilon, merchant, Claudette C.Pilon, housewife, wife of said Gaétan Pilon, and Jean-Marc Sureau, merchant, nil three of Saint-Clet, for the following purposes: 26 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Ile Perrot Auto Parts Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 31, Grand Boulevard, Ilc-Perrot, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4759-09 To carry on business as garage-keepers, and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"He Perrot Auto Parts Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 31 Grand Boulevard, Ile-Perrot, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 4759-69 Les Immeubles J.F.Morisseltc liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour dc juin 1969, constituant en corporation: Femand Morissclte junior, 960, rue Pouliot, Saintc-Foy, Jean Moris-sette, 1471, rue St-Paul, L'Anciennc-Lorcttc, tous deux gérants, et Pierre Thivierge, comptable, 1550, boulevard Xcuvialc, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, dc construction et de placement, sous le nom dc « Les Immeubles J.F.Morissctte ltée », avec un capital total dc S40.000, divjsé en 400 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1355, Honte Nationale, numéro 2, L'Ancienne-Lorclle, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.32506-o 2987-09 Les Immeubles J.F.Morisseltc liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of June, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Fcrnand Morissctte Jr., 960 Pouliot St., St.Foy, Jean Morissctte, 1471 St-Paul St., Anciennc-Lorettc, both managers, and Pierre Thivierge, accountant, 1550 Neuvialc Blvd., Québec, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction und investment company, under the name of \"Les Immeubles J.F.Morissette ltée\", with a total capital slock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head ollice of the company is at 1355 National Highway No.2, Ancicnne-Loreltc, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 29S7-09 Immeubles Lineltc inc.Avis est donné qu'en vertu dc la premiere partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en dale du 29e jour d'octobre 1969.constituant en corporation: Gilles l'harand, Rolland llasticn, tous deux notaires, et Jovcttc Chapdelaine, secrétaire, fille majeure, tous trois île 521, rue Sherbrooke est, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, dc placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « Immeubles Linctte inc.\", avec un capital total dc 8300,000.divisé en 3,000 actions ordinaires dc 8100 chacune.Le siège sociul de la compagnie est 700.boulevard Crémazie ouest, chambre 220, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Pnilippe Bouchard.32506-o 5286-09 Immeubles Liueltc inc.Notice is given that under Pari I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Phurand, Rolland Bastien, both notaries, and JovcttC Chapdelaine, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 521 Sherbrooke Street Fast, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, investment and holding company, under the name of \"Immeubles Linctte inc.\", with a total capital slock of 8300,000, divided into 3,000 common shares of S100 each.The head office of the company is at 700 Crémazie Boulevard Fast, suite 220.Montreal, judicial district, of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial I list il ut ions.Com punies and Cooperatives.32506 52K6-69 Imprimerie Vagmur limitée Vagmar Printing Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Guy Gagnier, 1095, Montmartre, Laval, Tiziano Mareolini, 3212, Bilodcuu, Montréal-Est, tous deux imprimeurs, et Roland Durand, avocat.234, Forcstwood Drive, Rosemère, pour les objets suivants: Imprimerie Vagmar limitée Vagmar Printing Limited Notice is given that under Part I of the Compnnies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Guy Gagnicr.1095 Montmartre, Laval, Tiziano .Mareolini, 3212 Bilodeau, Montreal Fast, both printers, and Roland Durand, advocate, 234 Forcstwood Drive, Rosemère.for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 27 S'établir imprimeurs, sous le nom de « Imprimerie Vagmar limitée \u2014 Vagmar Printing Limited ».avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.I/c siège social dc la compagnie est 1075, houlevard Laurier.Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre îles institutions financières, compagnies cl cooperalircs, Ls-Philippe Bouciiahd.32500 5208-69 To carry on business as printers, under the name of \"Imprimerie Vagmar limitée \u2014 Vagmar Printing Limited\", with a total capital slock of 840,000, divided into 10.000 common shares of a par value of SI each and 30,000 preferred shares of a par value of SI each.The head ollice of the company is at 1075 Laurier Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiiuppe BouciiAiti), Dcpuly Minister of Financial Inslilnlions, Companies and Cooperalircs.32500-o 5208-69 Iiiterprovincial Parts 70 Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la premiere partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Rosaire Fournier, marchand, 13.des Plaines, Pierre Béliveau, commis, 32, Alice, tous deux de Victoriavillc, et Louise Lcclcrc, secrétaire, fille majeure, 2, Belleau, Arthabaska, pour les objets suivants: Faire le commerce de pièces pour camions, machinerie lourde, tracteurs ou autres machineries, sous le nom de « Intcrprovineinl Parts 70 Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est Parc Industriel, Vicloriaville, district judiciaire d'Artha-baska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILIPPE BOUCIIAIU).32506-O 5152-69 Iiiterprovincial Parts 70 Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Actj lelters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rosaire Fournier, merchant, 13 des Plaines, Pierre Béliveau, clerk, 32 Alice, both of Victoriavillc, and Louise Leelcrc, secretary, spinster of the full age of majority, 2 Belleau, Arthabaska, for the following purposes: To deal in truck parts, heavy machinery, tractors, or other machinery, under the name of ''Interprovincial Parts 70 Inc.\", with a total capital slock of S40.000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Industrial Park, Victoriavillc, judicial district of Arthabaska.Ls-Piiiuppe Bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5152-69 Jardins de la Concorde liée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de lu province a accordé tics lettres patentes, en date du 9e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Arthur A.Yanofsky, Asher Kahn et Jeffrey A.Brull, tous trois avocats, dc 1501, Place Ville Marie, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de «Jardins de la Concorde ltée», avec un capital total dc 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 1760, boulevard des Laurentides, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.32506-o 4905-69 Jardins dc la Concorde Itee Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur A.Yanofsky, Asher Kahn and Jeffrey A.Brull, all three advocates, of 1501 Place Ville Marie, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Jardins de la Concorde ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 1760 Laurentian Blvd., Laval, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4905-69 Javel Concenlrcx Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Aaron Pollack, 900, avenue Rockland, Isidore Greenbaum, 615, avenue Westluke, tous deux avocats, et Janice McKen/.ie, secrétaire, célibataire, 4985, chemin de la Côte Saint-Luc, app.9, tous les trois de Montréal, pour les objets suivants: Javcl Coiicciitrcx Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Aaron Pollack, 900 Rockland Avenue, Isidore Greenbaum, 615 Westluke Avenue, both advocates, and Janice McKenzie, secretary, spinster, 4985 Côte St.Luc Road, Apt.9, all three of Montreal, for the following purposes: 28 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 L'industrie et le commerce de produits chimiques, eau de Javcl, composés et dérivés d'iccux, sous le nom dc « Javel Conccntrex Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-mini sire des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32500 5044-69 To manufacture and deal in chemicals, javel, compounds or derivatives thereof, under the name of \"Javel Concentrex Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a par value of 810 each and 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-PllILIPPH bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5044-09 Jubilee Québec Holdings Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour «l'octobre 1969, constituant en corporation: Jean de Brabant, 3816, Marlowe, Joel Avery Silcoir, 3250, Forest Hill, tous deux dc Montréal, et Robert F.Reynolds, 350, Côte Vertu, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire de la prospection et des recherches pour trouver des mines et des minéraux, sous le nom de « Jubilee Québec Holdings Limited», avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est 360 ouest, rue Saint-Jacques, bureau 1710, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, LS-PlIILIPPE bouchard.32506 5251-69 Jubilee Québec Holdings Limited Notice is given that under Pnrt I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean dc Brabant, 3816 Marlowe, Joel Avery Silcolî, 3250 Forest Hill, both of Montreal, and Robert E.Reynolds, 350 Cote Vertu, Saint-Laurent, all three advocatcs.for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Jubilee Quebec Holdings Limited\", with a capital stock divided into 40,000 shares without par value.The head oflicc of the company is at 360 St.James Street West, Suite 1710, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inisler of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.32506-o 5251-69 King Steer Restaurant Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi îles compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Nikolaos Kjua-giannis Andreas Karagianuis et Riga-.Kara-giannis, tous trois cuisiniers, de 1.009, Bernard, app.6, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter un commerce dc restaurateurs, sous le nom dc « King Steer Restaurant.Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et.2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 4983-69 Lanthier & Langcvin inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des Ici tirs patentes, en date du 5e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Darquis Langcvin, comptable, Emile Lanthier, commerçant, et Maurice Paquin, gérant, tous trois de Saint-Aimé-du-Lac-dcs-Ilcs, pour les objets suivants: Exploiter toutes sortes de salles de spectacle |MHir fins éducatives ou dc divertissements, sous le nom de « Lanthier & Langcvin inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.King Steer Restaurant Ltd.Notice is given that, under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Kith day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Nikolaos Kurugiuunis, Andreas Karagianuis und Bigas Karagiannis, all three cooks, of 1009 Bernard, apt.0.Montreal, for the following purposes: To carry on business as rcstauranteurs, under the name of \"King Steer Restaurant Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a par value of 810 each and 2,000 preferred shares of a par value of 810 each., The head ollice of the company is al Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Pii i i.i ppi: Boum au n.Deputy Minister of Financial Inslilnlions, Companies and Cooperalircs.32506-o 4983-69 Lanthier & Langcvin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Darquis Langcvin, accountant, Emile Lanthier.trader, anil Maurice Paquin.manager, all three of Saint-Aimé-dii-Lnc-dcs-Ilcs, for the following purposes: To o|K'rule all kinds of theatres for educational or entertainment purposes, under the name of \"Lanthier & Langcvin inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 1.000 common shares of 810 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1070, Vol.102, No.1 29 lx\" siège sociul «le lu compagnie est ù Saint-Aiiné-(lii-l.ue-(les-Iles.tlistrict judiciaire de Lu-hclle.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl cooperalircs, Ls-PlIIUPPK Hoi i'h a u n.325()- 4810-00 I.an l'ion & frère inc.Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres pntentes, en date du 31c jour d'octobre 1969, constituant en cor[M>ration : Picrrc-L.Lapointe, 155, Marcotte, Alexander S.Konigsberg, 2378, Frcnette, tous deux de Snint-Laurcnt, et Jacques Lemaitrc-Auger, 8462, Drolet, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce des huiles, graisses, pétroles, et tous leurs produits, et du gaz naturel, sous le nom de « Luurion & frère inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et en 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 959, rue dc Liuiaudière, Jolictte, district judiciaire dc Jolictte.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.32506-u 5304-69 C.Lcbcl ltée Avis est donné qu'en vertu dc lu première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres pntentes, en date du 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Georges Lcbcl, commerçant, Aliettc Gcndron, ménagère, é|>ousc dudit Georges Lcbcl, tous deux de 352, rue Laval sud, et Gcorges-II.Vignola, chef dessinateur, 72, rue Dollard, tous trois de Rimouski, (Kiiir les objets suivants: Exploiter des magasins dc vêtements, lingeries et literies de toutes sortes, sous le nom de « G.Lcbcl ltée >, avec un capital total de S75.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $100 chacune et en 650 actions privilégiées d'une valeur nominale dc 8100 chacune.Le siège social de lu compagnie est Centre Commercial Co-Op Gro, Uimouski, district judiciaire dc Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.32506-o 5202-69 The head ollice of the company is at Saint-Aimé-orution Ltd.», avec un capital total de S75.000, divisé en 750 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Sainte-Hélène, district judiciaire dc Kumourasku.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalircs, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5110-69 .Martin Maltais inc.Avis est donné qu'en vertu «le lu première partie «le lu Loi «les compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date «lu 5e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Martin Maltais, 143, Cookshire, Normand-E.Maltais, 127, Jameson, tous deux commerçants, dc East Angus, et Jean-Claude (Juillet, comptable.897, Des Des Muguets, Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de meubles et de nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Martin Maltais inc.», avec un capital totul de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires dc $100 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.S40.000, divided into 600 common shares of u nominnl value of SI each and into 3,940 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head ollice of the company is at 426 Sherbrooke Street Fast, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4914-69 Roger Lyonnais inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11 th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Roger Lyonnais, chartered accountant, Madeleine Ravary, housewife, wife of said Roger Lyonnais, both of 554 Davaar, Outremoiit, and Alix Bédnrtl, secretary, 130 St-Jacques, Longucuil, for the following purposes: To carry on business as administration counsellors, under the name of \"Roger Lyonnais inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 preferred shares of a nominal value of 810 each, 15,000 class \"A\" sluvrcs of a nominnl value of SI each und into 5,000 class \"B\" slut res of a nominal value of 81 each.The head ollice of the company is at 554 Davaar Street, Outrcmont, judicial district of Montreal.Ls-Piiii.ii'pk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.32506 4456-69 The Maine Lumlier Corporal inn Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Thériault, uccountaul, Félix Thériault, ojierator, and Thérèse Ouellct.housewife, wife of the said Félix Thériault, all three of Sant-Hélène, for the following purposes: The lumber industry and trade, under the name of \"The Maine Lumber Corporation Ltd.\", with a total capital stock of $75,000, divided into 750 common shares of $100 each.The head oflicc of the company is at Sainte-Hélène, judicial district of Kamouraska.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5110-69 Martin Maltuis inc.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters patent, bearing dulc the 5th day of November, 1969, have l>ccn issued by the Lieutenant-Governor of the Province.incorporating: Marl in Maltais, 143 Cookshirc.Normand-E.Maltais, 127 Jameson, both traders, of East Angus, ami Jean-Claude Guillet, accountant, 897 Des Muguets, Sherbrooke, for the following purposes: To deal in furniture and novelties of nil kinds, under the numc of \"Martin Maltais inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of $100 each und 300 preferred shares of SI 00 euch. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January S, 1970, Vol.102, No.1 33 Le siège social de la compagnie est à East Angus, district judiciaire dc Saint-François.Le tout-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3250Ô-o 5167-69 Marché Benoit Lavoie inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le licutcnunt-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Léonard Dufour, comptable, 648, de la (lare, Hélène Dcscliryver, \u2022'\u2022pou se de Robert-Armand Nolin, 716, des Remparts, et Hélène Richard, épouse de Puul-H.Fortin, 16, St-Luc, ces deux dernières secrétaires, tous trois d'Alma, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, bouchers et quincailliers, sous le nom de « Marché Benoit Lavoie inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 200 actions ordinuires de S100 chacune et en 200 actions privilégiées dc S100 chacune.\\x siège social dc la compagnie est à Aima, district judiciaire de Robcrval.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-O 4553-69 Marché Paul Beaumier ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province n accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Adèle Gugnon, fille majeure, 111, (îeorges, Charles (îagnon, 26, Guévremont, tous deux de Sorcl, et Gaston Fontaine, 1907, Cardin, Tracy, tous trois comptables, pour les objets suivants: l'aire allaircs comme épiciers-bouchers, sous le nom dc « Marché Paul Beaumier ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 30 actions ordinaires de $10 chacune, 100 actions privilégiées classe « A » dc 81 chacune et en 396 actions privilégiées classe « B » dc $100 chacune.lx siège social dc lu compagnie est ù Nicolet, district judiciaire dc Nicolet.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4415-69 The head office of the company is at East Angus, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5167-69 Marché Benoit Lavoie inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Léonard Dufour, accountant, 648 de la Gare, Hélène Deschryver, wife of Robert-Armand Nolin, 716 des Remparts, and Hélène Richard, wife of Puul-H.Fortin, 16 St-Luc, the latter two secretaries, all three of Alma, for the following purposes: To carry on business as grocers, butchers, and hardware merchants, under the name of \"Marché Benoit Lavoie inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of S100 euch und into 200 preferred shares of 3100 each.The head office of the company is at Alma, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.32506 4553-69 Marché Paul Beaumier ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adèle Gagnon, spinster of the full age of majority.111 Georges, Charles Gagnon, 26 Guévremont, both of Sorcl, and Gaston Fontaine, 1907 Cardin, Tracy, all three accountants, for the following puriwses: To curry on business as grocers and butchers, under the name of \"Marché Paul Beuumicr ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30 common shares of $10 each, 100 preferred class \"A\" shares of $1 each und 396 preferred class \"B\" shares of $100 each.The head office of the company is at Nicolet, judicial district of Nicolet.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4415-69 Marie-Hélène, Boutiques d'Escompte inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Coulombe, avocat, route rurale numéro 4, Françoise Fou-i|iiet, fille majeure, 1011, boulevard McMannmy, et Carole St-Roch, épouse de Jean-Guy St-Roch, 1060, rue Fédéral, ces deux dernières secrétaires, tous trois dc Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous produits, articles ou marchandises, sous le nom de « Marie-Hélène, Boutiques d'Escompte inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 900 actions ordinaires ¦le SI chacune et en 3,910 actions privilégiées de S10 chacune.Marie-Hélène, Boutiques d'Escompte inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Coulombe, advocate, rural route number 4, Françoise Fouquet, spinster of the full age of majority, 1011 McManumy Blvd., and Carole St-Roch, wife of Jean-Guy St-Roch, 1060 Fédéral St., the latter two secretaries, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in nil products, goods or merchandise, under the name of \"Marie-Hélène, Boutiques d'Escompte inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 900 common shares of $1 each and 3,910 preferred shares of $10 each. 34 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Le siège social de la compagnie est 919, ru-Muloin, Sherbrooke, district judiciaire dc Sainte François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiiuppe Bouciiahd.32506-o 5023-69 Rosaire Menard inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Rosaire Ménurd, commerçant, Françoise Robillard, ménugère, épouse dudit Rosaire Ménard, tous deux dc 181, boulevard Valois, Dorion, et Laurent Menant, chauffeur, chemin St-Grégoire, Les Cèdres, pour les objets suivants: Faire le commerce d'huiles, graisse, pétroles, et tous leurs produits et du gaz naturel, sous le nom de « Rosaire Ménard inc.», avec un capital total de $40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 181, boulevard Valois, Dorion, district judiciaire de Bcuti-harnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 5037-69 Mettano Paper Products Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de novembre 1969, constituant en corporation : Samuel Wex, 21, chemin de Clcve, Hampsteud, Stanley L.Cytryn-baum, 95, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, tous deux avocats, et Erica Hume, secrétaire, épouse de Jolin IL Hume, 1210B, Havre îles Iles, Laval, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce du papier et des produits dc toutes sortes dérivant du papier, sous le nom dc « Mettano Paper Products Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 350 actions privilégiées d'une valeur au pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouciiahd.32506 5366-69 Aimé Meunier inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnunt-gouverneur dc la province a accordé «les lettres patentes, en date du 3c jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Morlin A.Aster, 6525, chemin de la Côte Saint-Luc, app.305, Montréal, Jack Lightstonc, 68, chemin Stratford, Hampstead, et Marvin Riback, 5621, avenue Palmer, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploités une entreprise de remorquage, dc destruction, de démolition et dc récupération dc toutes sortes, sous le nom de « Aimé Meunier inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 cliacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.The head office of the company is at 919 Maloin St., Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5023-69 Rosaire Ménard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rosaire Ménard, trader, Françoise Robillard, housewife, wife of said Rosaire Ménard, both of 181 Valois Boulevard, Dorion, und Laurent Ménurd, driver, St-Grégoire Road, Les Cèdres, for the following purposes: To deal in oils, greases, petroleums und all their products and natural gas, under the name of \"Rosaire Ménard inc.\", with u total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 181 Valois Boulevard, Dorion, judicial district of Beau-harnois.Ls-Pllluppe bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.32506 5037-69 Mettano Paper Products Ltd.Notice is given thnt under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Samuel Wex, 21 Clevc Road, Hampsteud, Stanley L.Cytrynbuum, 95 Roxtou Crescent, Montreal West, both advocates, und Erica Hume, secretary, wife of John B.Hume, 1211115 Havre des Iles, Laval, for the following purposes: To manufacture and dcul in paper and paper products of all kinds, under the name of \"Mettano Paper Products Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a pur vuluc of $1 each and 350 preferred shares of a par value of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5366-69 Aimé Meunier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Morlin A.Aster, 6525 Côte St-Luc Road, apt.305, Montreal, Jack Lightstonc, 68 Stratford Road, Hampstead, and Marvin Riback, 5621 Palmer, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of towing, wrecking, demolition, salvaging in all its branches, under the name of \"Aimé Meunier inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 35 Le siège social de la compagnie est 705, rue Roland-Forgct, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.32506 4258-69 The head office of the company is at 795 Roland Forget Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4258-69 Miiair Aviation Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: J.-Claude Bachand, avocat, Denise-Marie Landry, secrétaire, célibataire, et Bibianc Côté, secrétaire, épouse de Gabriel Côte, tous trois du 1155 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie d'aviation et dc service aérien et faire le commerce d'avions dc toutes sortes et d'équipement, pièces et accessoires pour avions, sous le nom dc « Milair Aviation Inc.», avec un capital total de 350,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 4,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI0 chacune.Le siège social de la compagnie est à Westmount, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32500 5301-69 Mitralux Media Corp.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Robert Vineberg, avocat, 1559 ouest, avenue des Pins, Barbara Komornicki, 4353, Saint-Urbain, Eleanor Johnson, 5327-A, Prince dc Galles, tous trois dc Montréal, et Maureen Montgomery, 30, Place Côte Vertu, Saint-Laurent, ces trois dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: S'établir agents de publicité, sous le nom dc «Mitralux Media Corp.», avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est 666 ouest, rue Sherbrooke, bureau 2004, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5093-69 Modern Decor (1969) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Morris Chaikclson, 4950, Ponsard, Mortimer Chaikclson, 5893, avenue Clanranald, tous deux avocats, dc Montréal, et Thérèse Perreault, secrétaire, célibataire, 5633 est, Henri-Bourassa, Montréal-Nord, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de meubles et accessoires d'ameublements de toutes sortes, sous le nom de « Modem Decor (1969) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.Milair Aviation Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: J.-Claude Bachand, advocate, Denisc-Marie Landry, secretary, spinster, and Bibianc Côté, secretary, wife of Gabriel Côté, all three of 1155 Dorchester Boulevard West, Montreal, for the following purposes: To carry on the business of an aviation and uir-service company and to deal in aircrafts of all kinds and aircraft equipment, parts and accessories, under the name of \"Milair Aviation Inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 4,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at West-mount, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5301-69 Mitralux Media Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Robert Vineberg, advocate, 1559 Pine Avenue West, Barbara Komornicki, 4353 St.Urbain, Eleanor Johnson, 5327-A Prince of Wales, all three of Montréal, and Maureen Montgomery, 30 Place Côte Vertu, Saint-Laurent, the latter three secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on business as advertising agents, under the name of \"Mitralux Media Corp.\", with a capital stock divided into 40,000 shares without par value.The head office of the company is at 666 Sherbrooke Street West, suite 2004, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5093-69 Modern Decor (1969) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Morris Chaikelson, 4950 Ponsard, Mortimer Chaikelson, 5893 Clanranald Avenue, both advocates, of Montreal, and Thérèse Perrcault, secretary, spinster, 5533 Henri Bourassa East, Montreal North, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and furniture novelties of every description, under the name of \"Modern Decor (1969) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S janvier 1970, 102' année, n\" 1 36 Le siège social de la compagnie est 2500, chemin Bates, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Philippe Bouciiahd.3250G 4958-09 Motel L'Étape inc.Avis est donné qu'en vertu de la première part ii- dc lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé «les lettres patentes, en date du 28c jour d'octobre 1909, constituant en corporation: Marcel Duquette, administrateur, Margot Bisaillon, ménagère, épouse dudit Marcel Duquette, tous deux de boulevard Paquette, et Maurice Duquette, étudiant, 235, dc lu Madone, tous trois de Mont-Laurier, pour les objets suivants: Exploiter des motels, hôtels, tavernes et restaurants, sous le nom de « Motel L'Étape inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc S10 chacune et en 200 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Mont-Laurier, district judiciaire dc Labcllc.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératires, Ls-Philippe Bouciiahd.3250G-o 5211-09 Musicair inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 6c jour dc novembre 1969, constituant en corporation : Paul-André Pichettc, technicien en audio-diffusion, Gertrude Laflam-mc, secrétaire, épouse dudit Paul-André Pichettc, tous deux dc 759, rue Lc-Paycur, Saintc-Foy, et Georges Laflamine, industriel, 11, rue Fraser, Lévis, pour les objets suivants: Divertir le public au moyen d'appareils, machines et dispositifs reproduisant le son et/ou l'image, sous le nom dc « Musicair inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 2057, me Branly, Saintc-Foy, district judiciaire dc Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4954-69 N.J.Realty Company Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: André Couture, 125, Trémoy, Noranda, Jean-Charles Coutu, 576, Perreault est, et Jacques Coutu, 203, Latulipc ouest, ces deux derniers de Rouyn, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et dc placement, sous le nom de « N.J.Realty Company Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.The head office of the company i3 at 2500 Bates Road, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4958-69 Motel L'Étape inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Duquette, administrator, Margot Bisaillon, housewife, wife of said Marcel Duquette, both of Paquette Boulevard, and Maurice Duquette, student, 235 de la Madone, ull three of Mont-Laurier, for the following purposes: To operate motels, hotels, taverns and restaurants, under the name of \"Motel L'Étape inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Mont-Laurier, judicial tlistrict of Labette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5211-69 Musicair inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th clay of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Paul-André Pichettc, audio-diffusion technician, Gertrude Laflammc, secretary, wife of said Paul-André-Pichcttc, both of 759 Le-Paycur Street, Sainte-Foy, and Georges Lafiam-me, industrialist, 11 Fraser Street, Levis, for the following purposes: To amuse the public by way of apparatus, machines or devices reproducing sound and/or picture, under the name of \"Musicair inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 2057 Branly Street, Sainte-Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4954-69 N.J.Realty Company Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Couture, 125 Trémoy, Norandu.Jean-Charles Coutu, 576 Perreault east, and Jacques Coutu, 203 Latuli]>c west, the latter two of Rouyn, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"N.J.Realty Company Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,0011 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 37 Le siège social de la compagnie est à Noranda, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5098-69 The head office of the company is at Noranda, judicial district of Rouyn-Noranda.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5098-69 Natha disque inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Yvon Lavallée, 2794, Des Ormeaux, Gilles Morin, 6455, boulevard Maurice Duplessis, app.2, tous deux marchands, et Alain Morin, gérant, 3677, Ste-Fu-¦hille, apt.23, tous trois dc Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce, l'entretien et la répara-lion d'appareils de radio, dc télévision, de reproduction sonore et de communication, accessoires électriques, instruments de musique, leurs parties et accessoires, sous le nom de « Natha disque inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 100 actions ordinaires dc $10 chacune et en 3,900 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 8644, Chau-inont, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5219-69 Natha disque inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Yvon Lavallée, 2794 Des Ormeaux, Gilles Morin, 6455 Maurice Duplessis Boulevard, Apt.2, both traders, and Alain Morin, manager, 3677 Stc-Famille, Apt.23, all three of Montreal, for the following purposes: To deal in, maintain ami repair radios, televisions, sonorous and communication reproductions, electrical accessories, musical instruments, their parts and accessories, under the name of \"Natha disque inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $10 euch and into 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 8644 Chau-mont, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5219-69 Nettoyeur Citadelle inc.Citadel Cleaners Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Murray Lapin, 167, Kdgchill.Westmount, Norman May, 55, Hol-tliam, Hampstead, et Ezra Beinhaker, 3328, Troie, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir nettoyeurs à sec, presscurs, teinturiers, buandiers cl raccommodeurs dc vêtements, tissus, articles et fournitures dc maison, sous le nom dc « Nettoyeur Citadelle inc.\u2014 Citadel Cleaners Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montreal, district judiciaire dc Montréal.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5193-69 Nettoyeur Citadelle inc.Citadel Cleaners Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Murray Lapin, 167 Edgehill, West-mount, Norman May, 55 Holtham, Hampstead, and Ezra Beinhaker, 3328 Troie, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as cleaners, presscrs, dyers, launderers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Nettoyeur Citadelle inc.\u2014 Citadel Cleaners Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of the par value of $1 each and 3,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5193-69 Nettoyeurs Maisonncuve inc.Maisonneuve Cleaners Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Jacques Lasry, acheteur, 3020, avenue Van Home, #16, Montréal, Leon Kidman, entrepreneur en électricité, et l'rancc.s Fitelovich, secrétaire, épouse dudit Leon Krdman, ces deux derniers du 6885, chemin Kni?rson, Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Nettoyeurs Maisonncuve inc.Maisonneuve Cleaners Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques Lasry, purchaser, 3020 Van Home Avenue, #16, Montreal, Leon Erdman, electrical contractor, and Frances Fitelovich, secretary, wife of the said Leon Erdman, the latter two of 6885 Emerson Road, Côte Saint-Luc, for the following purposes: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n' 1 38 S'établir nettoyeurs ii sec, sous le nom de « Nettoyeurs Maisonncuvc inc.\u2014 Mnisonneuve Cleaners Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.\\x siège social de la compagnie est 2125 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5364-69 Norac Lumber Co.Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jacqueline Larochcllc commerçante, veuve de Gonzuguc Caron, Saint-Jean-de-la-Lande, Gaétan Duval, comptable, Saint-Georges, et Wilfrid Caron, commerçant, Saint-Benjamin, pour les objets suivants: Industrie et commerce île bois, sous le nom de « Norac Lumber Co.Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 800 actions ordinaires de $50 chacune.I/e siège social dc la compagnie est à Saint-Jcan-dc-la-Lande, district judiciaire de Beaucc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILIPPE Bouchard.32506-o 4290-69 Normandie Mining Corporation Ltd.(No personal liability) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc septembre 1969, constituant en corporation: G.Harold Pickcl, 47, Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505, Moore, Laval, Guy-E.Boisvert, 4976, Glcncairn, tous trois avocats, Yolande Poliseno, réceptionniste, célibataire, 7425, Querbes, et Denysc Marcoux, secrétaire, célibataire, 1488, Galt, ces trois derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Faire de la prospection et des travaux d'exploration pour trouver des mines et des minéraux, sous le nom dc « Normandie Mining Corporation Ltd.» (No personal liability), avec un capital total de $5,000,000, divisé en 5,000,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le Bout-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 4682-69 Norsam Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accorde des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Irving I.Finkclberg, avocat, 35, Merton Crescent, Hampstead, Rosa Bergman, 2800, Place Darlington, app.21, et Patricia Borlace, 5225, Randall, ces deux dernières secrétaires, célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: To carry on business as cleaners, under the name of \"Nettoyeurs Maisonneuve inc.\u2014 Maisonncuvc Cleaners Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at 2125 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5364-69 Norac Lumber Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacqueline Larochcllc, trader, widow of Gonzaguc Caron, Saint-.Ican-de-Lande, Gaétan Duval, accountant, Saint-Georges, and Wilfrid Caron, trader, Saint-Benjamin, for the following purposes: The industry and trade of wood, under the name of \"Norac Lumber Co.Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 800 common shares of $50 each.The head office of the company is at Saint-Jean-dc-la-Lande, judicial district of Beaucc.Ls-PiliLiPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4290-69 Normandie Mining Corporation Ltd.(No personal liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, Guy-E.Boisvert, 4976 Glcncairn.all three advocates, Yolande Poliseno, receptionist, spinster, 7425.Querbes, and Denysc Marcoux, secretary, spinster, 1488 Gait, the latter three of Montreal, for the following purposes: Prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Normandie Mining Corporation Ltd.\" (No personal liability), with a total capital stock of $5,000,000, divided into 5,000,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4682-69 Norsam Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province incorporating: Irving I.Finkclberg, advocate.35 Morton Crescent, Hampstead, Rosa Bergman.2800 Darlington Place, apt.21, and Patricia Borlacc, 5225 Randall, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 Exploiter une compagnie de construction et de placement, sous le nom dc « Norsam Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $1 chacune et 39,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILIPPE bouchaiid.32506 5010-69 North American Personel Consultants Ltd.Conseillers en Personnel Nord-Américains ltée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Richard S.Gottlieb, 7519, chemin Bailey, Arthur Marcovitch, 1540, Summervillc, et Lawrence Glazer, 7920, Kings-ley, tous trois avocats, dc Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: S'établir conseillers ou agents pour toute entreprise personnelle ou commerciale ou pour toute organisation industrielle pour le recrutement et la sélection du personnel, sous le nom de « North American Personel Consultants Ltd.\u2014 Conseillers en Personnel Nord-Américains ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et.coopératires, Ls-Philippe Bouchard.32506 5302-69 Peinture Opale inc.Opal Paint Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Léo Toulouse, gérant, Hélène Desjardins, ménagère, épouse dudit Léo Toulouse, tous deux de 278, Walnut, Saint-Lambert, et J.-Philippc Hudon, garagiste, 2121, rue Disraeli, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc peintures, polis, enduits colorants, couleurs, vernis, laques, produits chimiques et matériaux de toutes sortes, sous le nom dc « Peinture Opale inc.1\u2014 Opal Paint Inc.», avec un capital total dc $100,000 divisé en 6.000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, ilistrict judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4677-69 Pelletier & associés inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de novembre 1969, constituant en corporation : Adrien-R.Paquette, 212, Bloomfield, Outremont, Louis-A.Toupin, 39 To carry on the business of a construction and investment company, under the name of \"Norsom Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 39,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5010-69 North American Personel Consultants Ltd.Conseillers en Personnel Nord-Américains ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Richard S.Gottlieb, 7510 Bailey Road, Arthur Marcovitch, 1540 Summervillc, and Lawrence Glazer, 7920 Kingslcy, all three advocates, of CAte Saint-Luc, for the following purposes: To act as consultants or agent for any personal or commercial enterprise or for any industrial organization in the search, selection of personnel, under the name of \" North American Personel Consultants Ltd.\u2014 Conseillers en Personnel Nord-Américains ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2.000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5302-69 Peinture Opale inc.Opal Paint Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Leo Toulouse, manager, Hélène Desjardins, housewife, wife of the said Léo Toulouse, both of 278 Walnut, Saint-Lambert, and J.-Philippc Hudon, garagc-kecper, 2121 Disraeli St., Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in paints, polish, coatings, colored coatings, colors, varnish, lacquer, chemical products and materials of all kinds, under the name of \"Peinture Opale inc.\u2014 Opal Paint Inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 6,000 common shares of $10 each and 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4677-69 Pelletier & associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Adrien-R.Paquette, 212 Bloom-field, Outremont, Louis-A.Toupin, 3455 McCar- ¦10 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 3455, McCarthy, Saint-Laurent, tous deux avocats, et Benoit Rivet, stagiaire, 4370, Brébeuf, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « Pelletier & associés inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de 81 chacune et en 300 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 9535, boulevard St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniLIPPE Bouchard.32506-o 5329-69 Phoebus Imports Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jason Ruby, 47, Place du Bois, Dollard-dcs-Ormcaux, John Michelin, 5754, rue Lockwcood, tous deux avocats, et Glacia Miller, secrétaire, fille majeure, 3201, avenue dc Forest Hill, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: La fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce dc toutes sortes dc produits, articles et marchandises, sous le nom dc « Phoebus Imports Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 81 chacune et 3,800 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à 2015, rue Drummond, bureau 650, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5266-69 Les Placements Immobiliers Duverco inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Jean-Marc Poulin, avocat, 3045, Savard, Saint-Laurent, Ruth De Kinder, secrétaire, épouse de Louis De Kinder, 10184, Marquette, Montréal, et Philippe Kirsch, stagiaire, 935, J.J.Joubert, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, dc construction et dc placement, sous le nom dc «Les Placements Immobiliers Duverco inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $1 chacune et en 3,900 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Anjou, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniupPE Bouchard.32506-o 5344-69 Les Placements JVD limitée Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Jacques-V.Desaul-niers, ingénieur-industriel, Nicole Bourgeois, thy, Saint-Laurent, both advocates, and Benoit Rivet, articled student, 4370 Brébeuf, Montreal, for the following purposes: To carry on business as garagc-kccpcrs and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Pelletier & associés inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 9535 St-Laurent Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5329-69 Phoebus Imports Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jason Ruby, 47 Place du Bois, Dollard-dcs-Ormcaux, John Michelin, 5754 Lockwood Street, both advocates, and Glacia Miller, secretary, fille majeure, 3201 Forest Hill Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture, import, export and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Phoebus Imports Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $1 each and 3,800 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 2015 Drummond Street, Suite 650, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5266-69 Les Placements Immobilier.- Duverco inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Marc Poulin, advocate, 3045 Savard, Saint-Laurent, Ruth Dc Kinder, secretary, wife of Louis Dc Kinder, 10184 Marquette, Montreal, and Philippe Kirsch, articled student, 935 J.J.Joubert, Laval, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Les Placements Immobiliers Duverco inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 3,900 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 \u2022 5344-69 Les Placements JVD limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jacques-V.Dcsaulniers, industrial engineer, Nicole Bourgcsois, housewife, wife of said QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 -Il ménagère, épouse dudit Jacques-V.Desaulnicrs, tous deux de 330, Beverley, et Paul-A.Erabrcgts, gérant, 1000, Churchill, tous trois de Mont-1 loyal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, dc placement et dc gestion, sous le nom de « Les Placements JVD limitée », avec un capital totul dc $40,000, divisé en 50 actions ordinaires de $10 chacune, 3,930 actions privilégiées classe « A » dc $10 chacune et en 200 uctions privilégiées dusse < B » dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est 330, Beverley, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 5309-69 Les Placements Ludo inc.Ludo Investments Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Dorima St-Jacques, homme d'affaires, 5, Gauthier, Lucien Bouchard, contremaître, 9, Gauthier, tous deux dc Musson, Lucien Lalondc, assureur, 25, Tuschereau, Hull, André-Guy Bégin, commerçant, 2, St-Louis, Pointc-Gatincnu, et Gérard Robert, notaire, Thurso, pour les objets suivants: Faire affaires comme préteurs d'argent, sous le nom de « Les Pincements Ludo inc.\u2014 Ludo Investments Inc.», avec un capital total de SI 50,000, divisé en 75,000 actions ordinaires dc $2 chacune.Le siège social de la compagnie est 5, rue Gauthier, Masson, district judiciaire dc Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 2752-69 Les Placements Norman Thompson inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Damase B risse tte, 243, rue MarieTRosc, André St-Jacques, 154, Anjou, et Pierre Dureault, 401, avenue de Lorraine, tous trois avocats, de longucuil, pour les objets suivants: Paire affaires comme compagnie de placement, sous le nom dc « Les Placements Norman Thompson inc.», avec un capital totul dc S500.000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune, 49,000 actions privilégiées de classe « A » de $10 chacune et en 5,000 actions privilégiées dc classe « B » de $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.1a: sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 4680-69 Placements Rosaire Courtemanche ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour dc septembre 1969, constituant en corporation: Rosaire Courte-manche, garagiste, Henriette Allaire, ménagère, Jacques-V.Desaulnicrs, both of 330 Beverley, and Paul-E.Embregts, manager, 1000 Churchill, ull three of Mount Royal, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Les Placements JVD limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 50 common shares of S10 each, 3,930 preferred class \"A\" shares of $10 each and into 200 preferred class \"B\" shares of SI each.The head office of the company is at 330 Beverley, Mount Royal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5309-69 Les Placements Ludo inc.Ludo Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bcuring dutc the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Dorima St-Jncqucs, businessman, 5 Gauthier, Lucien Bouchard, foreman, 9 Gauthier, both of Masson, Lucien Lalondc, insurer, 25 Taschereau, Hull, André-Guy Begin, trader, 2 St-l.oiiis.Pointc-Gatincau, and Gérard Robert, notary, Thurso, for the following purposes: To carry on business as money lenders, under the name of \"Les Placements Ludo inc.\u2014 Ludo Investments Inc.\", with n total capital stock of $150,000, divided into 75,000 common shares of S2 each.The head office of the company is at 5 Gauthier Street, Masson, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 2752-69 Les Placements Norman Thompson inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bcuring dutc the 29th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Damasc Brissette, 243 Marie-Rose Street, André St-Jacques, 154 Anjou, and Pierre Dureault, 401 de Lorraine Avenue, all three advocates of Longucuil, for the following purposes : To curry on business us an investment company, under the name of \"Les Placements Norman Thompson inc.\", with a total capital stock of S500.000, divided into 5,000 common shares of SI each, 49,000 preferred class \"A\" shares of $10 each and into 5,000 preferred cluss \"B\" shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalircs.32506 4680-69 Placements Rosaire Courtemanchc ltée Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Rosaire Courtemanche, garage-keepers, Henriette Allaire, housewife, wife of 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 épouse dudit Rosaire Courtemanchc, tous deux de 935, Bourassa, Saint-Hyacinthe, et Gilles Lefebvre, assureur-vie, 350, Cûte Vertu, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc portefeuille, dc placement et de gestion, sous le nom dc « Placements Rosaire Courtemanchc ltée», avec un capital total de 840,000, divisé en 10 actions ordinaires de 8100 chacune, 3,897 actions privilégiées classe « A » dc 810 chacune et en 30 actions privilégiées classe « B » dc 81 chacune.Le siège social de la compagnie est 1090, des Cascades, Saint-Hyacinthe, district judiciaire dc Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4620-69 said Rosaire Courtemanche, both of 935 Bourassa, Saint-Hyacinthe, and Gilles Lefebvre, life-insurance agent, 350 Côte Vertu, Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on business as a holding investment and management company under the name of \"Placements Rosaire Courtemanchc ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10 common shares of 8100 each, 3,897 class \"A\" preferred shares of $10 each and 30 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head oflicc of the company is at 1090 Des Cascades, Snint-Hyacinthc, judicial district of Saint-Hyacinthc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4620-69 Plasbec inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de septembre 1969, constituant en corporation: François Boisclair, 702, Hartland, Outremont, Jean-Louis Lamou-reux, 10581, Grande-Allée, Yvon Brizard, 1100, McGregor, app.710, Guy Duranlcau, 3825, St-Denis, Jacques Lamourcux, 7136, deLorimicr, tous cinq avocats, Rhéa Gaudrcau, secrétaire, épouse de Jean Campcnu, 6402, Louis-Dupiré, tous six dc Montréal, Diane Jodoin, 10936, Armand-Lavcrgnc, Montréal-Nord, Lise Rivesl, 147, de l'Église, L'Assomption, toutes deux secrétaires, 'filles majeures, et Jcanninc Houdc, secrétaire, épouse dc Marcel Galal, 5855, Char-mcnil, Saint-Léonard, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc toutes sortes d'articles faits en tout ou en partie avec du plastique ou avec des matériaux similaires, sous le nom dc « Plasbcc inc.», avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social dc la compagnie est à Lanoraic-d'Autray, district judiciaire dc Jolictte.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32506-o 4710-69 Plasbcc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: François Boisclair, 702 Hartland, Outremont, Jean-Louis Lamoureux, 10581 Grande-Allée, Yvon Brizard, 1100 McGregor, apt.710, (îuy Duranlcau, 3825 St-Denis, Jacques Lamoureux, 7136 De Lorimicr, all five advocates, Rhéa Gaudrcau, secretary, wife of Jean Cam-pcau, 6402 Ixniis-Dupiré, all six of Montreal, Diane Jodoin, 10936 Armand-Lavcrgnc, Montreal-North, Lise Rivest, 147 De l'Église, L'Assomption, both secretaries, spinsters of the full age of majority, and Jcanninc Houde, secretary, wife of Marcel Galal, 5S55 Charmenil, Saint-Leonard, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of articles made in whole or in part of plastic or similar materials, under the name of \"Plasbcc inc.\", with a capital-stock divided into 40,000 common shares without nominal value.The head office of the company is nt Lanornie-d'Autray, judicial district of Jolictte.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4710-69 Plastic Shield Products (Canada) Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-Paul Bélislc, Edna Bélisle, épouse dudit Jean-Paul Bélislc, tous deux administrateurs en affaires, 3390, rue Belvédère, Brossard, et Paul Roger, employé d'hôtel, 4020, rue Prieur, Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc toutes sortes dc produits, articles et marchandises, sous le nom «le « Plastic Shield Products (Canada) Inc.», avec un capital total de 8100,000, divise en 100,000 actions ordinaires dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est 4451, rue Saint-Hubert, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 4985-69 Plastic Shield Products (Canada) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Kith day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jean-Paul Bélislc, Edna Bélislc, wife of the said Jean-Paul Bélislc, both business executives, of 3390 Belvédère Street, Brossard.and Paul Roger, hotel man, 4020 Prieur Street, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Plastic Shield Products (Canada) Inc.\", with a total capital stock of 8100,000.divided into 100,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 4451 St.Hubert Street, Montreal, judicial tlistrict of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4985-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 43 Pocart inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Luc Racicot, 146, St-Alexandrc, Longucuil, Pierre Thomas, 250, Des Êcorcs, Laval, tous deux avocats, et Amalia Corbo, publiciste, épouse dc Gérald Bcuuvais, 256, chemin Côte Ste-Catherine, Outremont, |>our les objets suivants: Exploiter toutes sortes de machines ou appareils servant au divertissement ou à l'amusement du public, sous le nom de « Pocart inc.», avec un capital total dc $40,000.divisé en 10,000 actions ordinaires dc $1 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalircs, Ls-Piiii.ippb Bouchard.32506-o 4991-69 Pocart inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Luc Racicot, 146 St-Alexandrc.Longucuil, Pierre Thomas, 250 Des Écores, Laval, both advocates, and Amalia Corbo, publicist, wife of Gerald Rcauvais, 250 Côte Stc-Cathcrine Road, Outrcmont, for the following purposes: To operate all kinds of machines or appliances used for the entertainment or amusement of the public, under the name of \"Pocart inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head oflicc of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4991-69 The Pontiac Protestant Home for the Aged Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-act ions: Dale Thomson, gérant, Orla Young, cultivateur, Carson Hodgins, vendeur, Percy, Bclshcr, menuisier, et Brent Horner, compositeur, tous les cinq de Shawvillc, pour les objets suivants: Administrer un centre de logement à prix modique et.de soins domiciliaires, construit à l'intention des personnes âgées dc la province de Québec, sous de nom dc « The Pontiac Protestant Home for the Aged ».Le montant auquel se limite la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou acquérir ln corporation est dc $1,000,000.Le siège social dc la corporation est à Shawvillc, district judiciaire de Pontiac.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 4757-69 Prcsco ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Bcrthe F.Grondin, ménagère, épouse de Jean-Marie Grondin, 5544, rue Charlcroi, Maurice Lacroix, marchand, 4332, Place Joubcrt, tous deux de Montréal-Nord, et Benoit Fccteau, analyste, 420, boulevard Robin, app.4, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme préteurs d'argent et comme compagnie dc construction, sous le nom de «Prcsco ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4901-69 The Pontiac Protestant Home for the Aged Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of Octol>er, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Dale Thomson, manager, Orla Young, farmer, Carson Hodgins, salesman, Percy Belsher, carpenter, and Brent Horner, compositor, all five of Shawvillc, for the following purposes: To administer a low cost housing and residential care centre built for the aged of the Province of Québec, under the name of \"The Pontiac Protestant Home for the Aged\".The amount to which the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $1,000,000.The head office of the corporation is at Shawvillc, judicial district of Pontiac.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4757-69 Presco ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Berthc F.Grondin, housewife, wife of Jean-Marie Grondin, 5544 Charlcroi St., Maurice Lacroix, merchant, 4332 Place Joubcrt, both of Montreal North, and Benoit Fccteau, analyst, 420 Robin Blvd., Apt.4, Laval, for the following purposes: To carry on business as money lenders and as a construction company, under the name of \"Prcsco ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4901-69 \u202214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Profit-Rama Ltd.Profit-Rama ltée Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Gilles Savoie, 1315, Panama, Pierre Sansoucy, 1311, Panama, tous deux de Brossard, et Rodrigue Plante, 440, Sherbrooke est, app.1401, Montréal, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom dc « Profit-Rama Ltd.\u2014 Profit-Rama ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4779-69 Publicité Jen-Dro inc.Jcn-Dro Advertising Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Gilles Drouin, agent-manufacturier, Laurcttc Brissettc, secrétaire, fille majeure, tous deux dc 3655, rue Papincau, et Léonard Bélanger, manufacturier, 5310, nie Charlemagne, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom dc < Publicité Jcn-Dro inc.\u2014 Jcn-Dro Advertising Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires dc $10 chacune et en 3,700 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.32506-o 5267-69 Quincaillerie Dante inc.Dante Hardware Inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de novembre 1969, constituant en corporation: Antonio Vcndittclli, Luigi Vendittclli et Giuseppe Vcndittclli, tous trois marchands, de 7094, Drolet, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous articles dc quincaillerie, accessoires électriques et matériaux «le construction, sous le nom de « Quincaillerie Dante inc.\u2014 Dante Hardware Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 6851, rue St-Dominique, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalircs, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5177-69 Profit-Rama Ltd.Profit-Rama ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Savoie, 1315 Panama, Pierre Sansoucy, 1311 Panama, both of Brossard, and Rodrigue Plante, 440 Sherbrooke east, Apt.1401, Montreal, all three administrators, for the following purposes: To carry on business as advertising contractors and consultants, under the name of \"Profit-Rama Ltd.\u2014 Profit-Rama ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4779-69 Publicité Jcn-Dro inc.Jcn-Dro Advertising Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Drouin, manufacturing agent, Laurcttc Brisscttc, secretary, spinster of the full age of majority, both of 3655 Papincau Street, and Léonard Bélanger, manufacturer, 5310 Charlemagne Street, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as publicity counsellors and contractors, under the name of \"Publicité Jcn-Dro inc.\u2014 Jen-Dro Advertising Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $10 each and into 3,700 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5267-69 Quincaillerie Dante inc.Dante Hardware Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of November, 1969, have licen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Antonio Vendittclli, Luigi Vcndittclli and Giuseppe Vendittclli, all three traders of 7094 Drolet, Montreal, for the following purposes : To deal in all kinds of hardware articles, electrical accessories and construction material, under the name of \"Quincaillerie Dante inc.\u2014 Dante Hardware Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 6851 St-Dominiquc Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5177-69 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 Résidence Bel Air de Buckingham inc.Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour dc novembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: .(os.McGurn, contremaître, 15, Lièvre Heights, Moisc-R.Duoust, marchand, 580, Principule, Michel Laçasse, travailleur social, 601, O'Ncil, Lucien Houle, bijoutier, 400, des Pins, Thomas-P.Laframboise, entrepreneur, 589, Laframboise, Horace Gauthier, commerçant, 602, Eddy, Roger D'Aoust, rentier, 501, Charles, Peter N.MacLachlan, médecin, 115, Lamennais, Ray Stunyar, ménagère, épouse de Avery Scott, 598, Eddy, et François Bcaupurlunt, notaire, 709, Georges, tous de Buckingham, pour les objets suivants: Fournir à des couples ûgés et à des personnes Agées des deux sexes, un foyer leur permettant de vivre en toute sécurité et duns l'atmosphère d'un véritable esprit de famille, sous le nom de « Résidence Bel Air dc Buckingham inc.».Le montant auquel est limitée la valeur «les biens immobiliers que peut uct'uérir et posséder lu corporation, est de 8500,000.Le siège sociul dc lu corporation est à Buckingham, district judiciaire dc Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pin lippe Bouciiahd.32506-o 4528-69 Restaurant Jardin d'Or inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Denis Kakaroubas, Nick Mêlas, tous deux du 7890 est, rue Sherbrooke, et Spiros Bafitis, 9175, rue Meunier, tous trois restaurateurs, de Montréal, pour les objets suivants: Tenir restaurant, sous le nom de « Restaurant Jardin d'Or inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 7955 est, rue Hochclaga, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5099-69 Restaurant Le Marie-France inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Maurice Forticr, administrateur, Lucienne Turgcon, ménagère, é|x>use dudit Maurice Forticr, tous deux de 2320, des Chutes, Jean-Marie Santerrc, administrateur, et Pauline Drouin, ménagère, épouse dudit Jean-Marie Santcrre, ces deux derniers de 1495, Jean ne-Man ce, tous quatre dc Québec, l>our les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom «le « Restaurant Le Marie-France inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.45 Résidence Bel Air de Buckingham inc.Notice is given that under Purt III of the Companies Act, letters putcnt, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Jos.McGurn, foreman, 15 Lièvre Heights, Moise-R.Duoust, trader, 580 Principul, Michel Laçasse, social worker, 601 O'Ncil, Lucien Houle, jeweller, 400 «les Pins, Thomas-P.laframboise, contractor, 589 Laframboise, Horace Gauthier, trader, 602 Eddy, Roger D'Aoust, annuitant, 501 Churles, Peter N.MacLachlan, doctor, 115 Lamennais, Ray Stanyar, housewife, wife of Avery Scott, 598 Eddy, and François Bcauparlant, notary, 709 Georges, all of Buckingham, for the following purposes: To furnish aged couples and the aged of both sexes with a home ullowing them to live within the security und utmosphcrc of a true family spirit, under the name of ' 'Résidence Bel Air de Buckingham inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire und possess, is $500,000.Tin- heud office of the corporation is at Bucking-hum, judicial district of Hull.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 4528-69 Restaurant Jardin d'Or inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Denis Kakaroubas, Nick Mclas, both of 7980 Sherbrooke Street East, and Spiros Bafitis, 9175 Meunier Street, all three restaurateurs, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Jardin d'Or inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at 7955 Hochelaga Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5099-69 Restaurant Le Marie-France inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, inror-porating: Maurice Forticr, administrator, Lucienne Turgeon, housewife, wife of said Maurice Fortier, both of 2320 des Chutes, Jean-Marie Santerrc, administrator, and Pauline Drouin, housewife, wife of said Jean-Marie Santerre, the latter two of 1495 Jcannc-Mance, all four of Québec, for the following purposes: To carry on business as restaurant-keepers, under the name of \"Restaurant Lc Marie-France inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and into 30,000 preferred shares of $1 each. 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S janvier 1970, 102e année, n\" 1 Le siège social de la compagnie est 581, boulevard Wilfrid-Hamcl, Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-minislre des inslilnlions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILIPPE BoUCHARD.32506-o 5256-69 The head office of the company is at 581 Wilfrid-Hamcl Boulevard, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5256-69 Restaurant Les Bergcroimes inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patentes, en date du 6c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Jean-L.Guilbeault, 4180, Melrose, Jean-Pierre Bonin, 5550, Baldwin, tous deux avocats, Michèle Opasinski, secrétaire, é]x>use de Jean-Claude Opasinski, 3895, Plamondon, et Gisela Woerncr, comptable, fille majeure, 3261, Forest Hill, app.50, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Les Bergeronncs inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montreal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 4498-69 Restaurant Les Bergcronnes inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Jcan-L.Guilbeault, 4180 Melrose, Jean-Pierre Bonin, 5550 Baldwin, both advocates, Michèle Opasinski, secretary, wife of Jean-Claude Opasinski, 3895 Plamondon, and Giscla Woerner, accountant, spinster of the full age of majority, 3261 Forest Hill, Apt.50, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Les Bergeronncs inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32501) 4498-69 La Revue de l'Homme d'Affaires (Québec) inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Michel Vaugeois, vendeur, Gilles Vaugeois, journalier, tous deux de 74, Langcvin.Bcauport, et Jean-Paul Gravel, photograveur.1380, Fiset, Sillery, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, éditeurs, entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom de « La Revue dc l'Homme d'Affaires (Québec) inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 330, rue St-Roch, suite 330, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5758-69 La Revue de l'Homme d'Affaires (Québec) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Michel Vaugeois.salesman, Gilles Vaugeois, labourer, both of 74 Langcvin, Bcauport, and Jean-Paul Gravel, photo-engraver, 1380 Fisct, Sillery, for the following purposes: To carry on business as printers, editors, advertising contractors and consultants, under the name of \"La Revue de l'Homme d'Affaires (Québec) inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 330 St.Roch St., Suite 330, Québec, judicial district of Quebec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5758-69 Soda inc.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Claude Piché, 1137, St-Laurent, app.2, André-F.Bélanger, 1489, Beckett, tous deux de Sherbrooke, et Louis Provcncher, 108, rue Lewis, Waterloo, tous trois étudiants, pour les objets suivants: Administrer tout genre de service pour étudier, encourager, promouvoir et servir les intérêts scientifiques, artistiques, culturels, sociaux, récréatifs, professionnels, athlétiques ou sportifs des membres, sous le nom de « Sada inc.».Sada inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate a corporation without share capital: Claude Piché, 1137 St-Laurent, Apt.2, André-F.Bélanger, 1489 Beckett, both of Sherbrooke, and I.nuis Provencher, 108 Lewis Street, Waterloo, all three students, for the following purposes: To provide all services in order to study, encourage, promote and serve the scientific, artistic, cultural, social, recreational, professional, athletic or sporting interests of the members, under the name of \"Sada inc.\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 \u202217 Le montant auquel est limitée lu valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder lu corporation, est dc $5,000,000.Le siège social de la corporation est ù l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François./,c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 5221-09 Salon Shcppard inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour d'octobre 1909, constituant en corporation: Laurent Breton, professeur, Louise Olivier, esthéticienne, épouse dudit Laurent Breton, tous deux dc 870, Du Coteau, et Adrien Olivier, maître dc poste, 1073, Boute dc l'Église, tous trois dc Saintc-Foy, pour les objets suivants: Exploiter îles salons dc coiffure, d'esthétique, de manicure et pédicure, sous le nom de « Salon Shcppard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 3,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1605, Shcppard, Sillery, district judiciaire dc Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 5200-69 Scan Microsystems Limited Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies,, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour d'octobre 1969, constituant en corporation: I.David Fleming, 65, Belvédère, Jean-Paul Gagnon, 556, Filia-treault, et David M.Bernstein, 4687, Bonavista, tous trois avocats, dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires en emmagasinant, récupérant et reproduisant des dossiers et des renseignements île toutes sortes et dc toutes descriptions, sous le nom de «Scan Microsystems Limited», avec un capital total divisé en 10,000 actions sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouciiahd.32506 5083-69 Louis M.Schefler Inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Clarence Reuben Gross, 790, avenue Lexington, Westmount, Joel Arnold Pinsky, 69, chemin Downshire, Hampstead, tous deux avocats, et Isoliel Nicholson, secrétaire, fille majeure, 3661, rue Sainte-Famille, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de quincaillerie, souvenirs, papeterie, jouets et autres articles du même genre, sous le nom dc « Louis M.Schcffer Inc.», avec un capital total dc $100,000, divisé en 100 uctions ordinaires de $1 chacune et 999 actions privilégiées dc $100 chacune.The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $5,000,000.The head oflicc of the corporation is at the University of Sherbrooke, Sherbrooke, judiciul district of Saint-François.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5221-69 Salon Shcppard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, in-cor|>orating: Laurent Breton, professor, Louise Olivier, acsthetician, wife of the said Laurent Breton, both of 870 Du Coteau, and Adrien Olivier, postmaster, 1073 Church Road, all three of St.Foy, for the following purposes: To operate hairdrcssing and aesthetics salons, and to give manicures and pedicures, under the name of \"Salon Shcppard inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at 1605 Shcppard, Sillery, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5200-69 Scan Microsystems Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of October, 1969, have l>cen issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: I.David Fleming, 65 Belvédère, Jean-Puul Gagnon, 656 Filiatrcault, and David M.Bernstein, 4687 Bonavista, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of storing, retrieving and reproducing records and information of every kind and description, under the name of \"Scan Microsystems Limited\", with a capital stock divided into 10,000 shares without par vuluc.The heud oflicc of the company is ut Montreul, judiciul district of Montreul.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5083-69 Louis M.Scheffer Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Clarence Reuben Gross, 790 Lexington Avenue, Westmount, Joel Arnold Pinsky, 69 Downshire Road, Humpstcad, both advocates, und Isobcl Nicholson, secretary, fille majeure, 3661 St.Famille Street, Montreal, for the following purposes: To deal in hardware, novelty stationery, toys and allied articles, under the name of \"Louis M.Scheffer Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $1 each and 999 preferred shares of $100 each. 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506 5007-69 Frank Scofield Agencies Ltd.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Ross Trenliolmc Clarkson 220, avenue Chester, Mont-Royal, Graham Nesbilt, 1524, ouest, avenue des Pins, app.3, et Philippe Mon tel, 2155, rue Muckay, ces deux derniers dc Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer îles marchandises de sport, vêtements de sport et toutes sortes d'agrès pour le sport, en fuirc le commerce, sous le nom de « Frank Scofield Agencies Ltd.», avec un capital-actions divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair.I.c siège social dc lu compagnie est 2411, rue du Lac Renaud, Sainte-Adèle, district judiciaire de Terrebonne.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératifs, Ls-Philippe Bouciiahd.32506 4764-69 Secrétariat des Syndicats Nationaux dc la Baie inc.Avis est donné qu'en vertu de lu troisième purtic dc la Loi des compagnies, le heu tenon t-gouverneur de la province a uccordé des lettres patentes, en date du 30e jour d'octobre 1909, constituant en corporation suns cupitul-actions: Clément Dufour, électricien, 655, Elgin, Bugot-ville, Marcel Brunei, vérificateur, 1033, 7e Avenue, et Raymond-Marie Tremblay, commis-comptable, 1691, 5e Avenue, ces deux derniers de Port-Alfred, pour les objets suivants: Établir et exploiter un club social, sous le nom dc « Secrétariat des Syndicats Nutionaux de lu Baie inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est dc $100,000.Ixî siège social de la corporation est ù Port-Alfred, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 2204-09 A.Séguin publicité inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de novembre 1909, constituant en corporation: Louis-Paul Nolet, comptable agréé, 3471, Kingston, Claude Savard, 7530, Des Érables, tous deux de Montréal, et Adélard-Simon Séguin, 12257, De Montigny, Pointe-aux-Tremblcs, ces deux derniers publicis-tes, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous le nom de « A.Séguin publicité inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 5007-69 Frank Scofield Agencies Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Ross Trenholme Clarkson, 220 Chester Avenue, Mount Royal, Graham Ncsbitt, 1524 Pine Avenue West, apt.3, and Philippe Mon tel, 2155 Mackay Street, the latter two of Montreal, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in sporting goods, sports clothing |and sporting equipment of all kinds, under the name of \"Frank Scofield Agencies Ltd.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without par value.The head office of the company is at 2411 Lac Rcnuud Street, Sainte-Adèle, judicial district of Terrebonne.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4754-69 Secrétariat des Syndicats Nationaux dc la Baie inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, benring date the 30th day of October 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incorporate u corporation without share capital: Clément Dufour, electrician, 655 Elgin, Bagot-ville.Marcel Brunet, uuditor, 1033, 7th Avenue, and Raymond-Muric Tremblay, accountant clerk, 1691, 5th Avenue, the latter two of Port-Alfred, for the following purposes: To establish and oi>crate a social club, under the name of \"Secretariat des Syndicats Nationaux dc la Baie inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is 3100,000.The head office of the corporation is at Port-Alfred, judiciul district of Chicoutimi.Ls-Piiilippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 2204-69 A.Séguin publicité inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of November, 1969, have been issued, by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Louis-Paul Nolct, chartered accountant, 3471 Hingston, Claude Savard, 7530 Des Érables, both of Montreal, and Adélard-Simon Séguin, 12257 De Montigny, Pointc-aux-Trembles, the latter two publicists, for the following purposes: To carry on business as advertising contractors and consultants, under the name of \"A.Séguin publicité inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 49 Le siège social de la compagnie est à Montreul, district judiciaire de Montréal, /.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PllILlPPK BoUClÎABD.3250G-o 556649 Sicem International incorporée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de novembre 1969.constituant en corporation: René-E.Rivurd.administrateur agréé.Louise Vaugeois, infirmière, épouse dudit René-E.Rivard.tous deux de 1730.l'arc Chcsnaye, Sillcry, et Milorad Stanojlovic.économiste, 9223.boulevard LaSalle.LâSulle.pour les objets suivants: Agir comme conseiller en administration, sous le nom de « Sicem Intcrnutional incorporée ».avec un capital divisé en 40.000 actions sans valeur nominale.Le siège social de lu compagnie est ù Québec, district judiciaire de Québec.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératires, Ls-Piiiuppe Bouchard.32500-o 5139-69 The head office of the compuny is at Montreal, judicial district of Montreal.i.- -1 ' 1I I i.i l'PK Hoi ' II .Mill.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5556-69 Sicem International incorporée Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the (ith (lay of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: René-E.Rivard, chartered administrator, Louise Vaugeois, nurse, wife of said René-E.Rivard.both of 1730 Pare Chesnaye, Sillery, and Milorad Stanojlovic.economist, 9223 LaSalle Boulevard, LaSalle.for the following purposes : To act as administration counsellors, under the name of \"Sicem International incorporée\", with a capital stock divided into 40.000 shares without nominal value.The head ollice of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Piii i.i im'k Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5139-69 Silverstaek Mines Ltd.(No personal liability) Mine Silverstaek ltée (l'as de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions île lu Loi des compagnies minières, le lieutenant-gouverneur de la province u accordé des lettres patentes, en date du 21e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: André Couture, 125, Trémoy, Noranda, Jean-Charles Coutu, 576, Perrcault est, et Jacques Coutu, 203, Latulipc ouest, ces deux derniers de Rouyn, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais, sous le nom dc « Silverstaek Mines Ltd.» (No personal liability) \u2014 « Mine Silverstaek ltée » (Libre dc responsabilité personnelle), avec un capital total de 87,000,000 divisé en 7,000,000 d'actions ordinaires de SI chacune.Le siège social de la compagnie est ù Rouyn, district judiciire dc Rouyn-Noranda.I.c sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératires, Ls-Piiilipph Bouchard.32506-o \u2022 5097-69 Simard Laveuse Service inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première partie dc lu Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1969, constituant en corporation: Lucille Simard, commerçante, veuve de Maurice Simard, 2991, Loyola, Jean-Paul Simard, commerçant, 2284, St-David, tous deux dc Giffard, et Marthe Morel, ménagère, épouse de Paul Turgcon, 1115, Brown, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens et faire le commerce et l'entretien de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom dc * Simard Laveuse Service inc.», avec un capital totul de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Silverstaek Mines Ltd.(No personal liability) Mine Silverstaek ltée (Pas dc responsabilité personnelle) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing dute the 21st day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incor|Kirating: André Couture, 125 Trémoy, Noranda, Jean-Charles Coutu, 576 Perreault cast, and Jacques Coutu, 203 Latulipe west, the latter two of Rouyn, all three advocates, for the following purposes: To carry out explorations or searches to discover mines and ores, under the name of \"Silver-stack Mines Ltd.\" (No personal liability) \u2014 \"Mine Silverstaek ltée\" (Libre de responsabilité personnelle\", with a total capital stock of $7,000,000.divided into 7,000,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at Rouyn, judicial district of Rouyn-Noranda.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 5097-69 Simard Laveuse Service inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of October, 1969, have been issued by the Licusenant-Govcrnor of the Province, incorporating: Lucille Simard, trader, widow of Maurice Simard, 2991 Loyola, Jean-Paul Simard, trader, 2284 St-David, both of Giffard, and Marthe Morel, housewife, wife of Paul Turgeon, 1115 Brown, Québec, for the following purposes: To carry on business as electricians and to deal in and repair all kinds of electrical appliances and accessories, under the name of \"Simard Laveuse Service inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each. 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phimppk Bouchard.32606-o 5089-09 Arthur Simoncau liée Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le licutcnunt-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en dute du 4c jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Arthur Simoncau, entrepreneur, Solange Simoncau, secrétaire, épouse dudit Arthur Simoneuu, tous deux de 662, 15c rue sud, (Jharny, et Roland Labrie, comptable, 832, Rougcmont, Saintc-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce dc toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Arthur Simoncau ltée », avec un capital total de S100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 5,000 actions privilégiées de S10 chacune.I,c siège social dc la compagnie est à Cliarny, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératires, Ls-Piiimppk Bouchard.32506-o 5458-69 La Société de Gestion C.K.B.inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour dc novembre 1969, constituant en corporation: Gilles-G.'Fessier, 445, Grenfeld, Hugues Ferron, 17, Lazard, tous deux avocats, dc Mont-Royal, et Jeannette Fournier, secrétaire, fille majeure, 3455, Rcd-palh, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de «La Société de Gestion CF.IL inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de 81 chacune, 3,900 actions privilégiées « A » de S10 chacune et en 800 actions privilégiées «B» de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciuirc de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phimppk Bouciiahd.32506-o 5422-69 La Société Immobilière Stc-Foy ltée Avis est donné qu'en vertu de la première purtic dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de novembre 1969, constituant eu corpora lion: Gilles Renaud, avocat, 3405, rue Linton, app.208, Lise Quesnel, 5138, Monclnir, et Muric-Édith Lebrun, 2150, rue St-Murc, upp.2003, ces «leux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois de Montréal, iKHir les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom dc « La Société Immobilière Stc-Foy ltée », avec un capital total dc S100.000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $100 chacune et en 900 actions privilégiées d'une valeur nominale de SI 00 chacune.The head ollice of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Phimppk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5089-69 Arthur Simoncau ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Arthur Simoncau, contractor, Solange Simoncau, secretary, wife of the said Arthur Simoncau, both of 662, 15th St.south, Charny, and Roland Labric, accountant, 832 Rouge-mont.St.Foy, for the following purposes: To curry on business us builders und general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Arthur Simoncau ltée\", with a total capital stock of $100.000, divided into 5,000 common shares of $10 each and 5,000 preferred shares of S10 each.The head ollice of the company is at Charny.judiciul district of Québec.Ls-Piiimppi: Bouciiahd, Deputy M inisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5458-69 La Société de Gestion C.E.B.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gillcs-G.Tcssicr, 445 Grenfeld, Hugues Perron, 17 Lazard, both advocates of Mount Royal, and Jeannette Fournier, secretary, spinster of the full age of majority, 3455 Redpath, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"La Société de Gestion C.K.B.inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 200 common shares of SI each, 3,900 preferred \"A\" shares of S10 each anil into 800 preferred \"B\" shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiii.ii'pk Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5422-69 Lu Société Immobilière Ste-Foy liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Renaud, advocate, 3405 Linton St., Apt.208, Lise Quesnel, 5138 Monclair.and Marie-Édith Lebrun, 2150 St-Marc St.Apt.2003, the two latter secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business os a real estate, construction und investment company, under the name of \"La Société Immobilière Ste-Foy ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of a nominal value of $100 each und 900 preferred shares of a nominal value of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 51 Le siège social de la compagnie est 111, rue dc Lauzon, Bouchervillc, district judiciaire de Montréal.I.c soii.i-iniiii.ilre des inslilnlions financières, compagnies el coopératires, Ls-Philippe Bouciiahd.:C2f)0G-o 5440-69 The head ollice of the company is at 111 do Lauzon St., Bouchervillc, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Dcpuly Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 \u2022 5440-69 Société Jeune Histoire Québec Avis est donné qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, le liculenant-gouverneur de la province a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de novembre 1969, constituant en corporation sans capital-actions: Doris Drolct, étudiante, fille majeure, 1063, St-l'nul, L'Ancicnnc-Lorclle, Paul Lnrocque, étudiant, 795, Terrasse Laurentienne, #7, Saintc-Foy, et Gilles Iléon, archiviste, 881, Lévis, Shawinigan, pour les objets suivants: Promouvoir la connaissance de l'histoire, sous le nom dc « Société Jeune Histoire Québec ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc 810,000.Le siège social de la corporation est 881, rue Lévis, Shawinigan, district judiciaire de Saint-Maurice./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.32506-o 4911-69 Société Jeune Histoire Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters (latent, bearing date the 12th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to incor|Kiratc a corporation without share capital: Doris Drolct, student, spinster of the full age of majority, 1063 St-Paul L'Ancicnnc-Lorette, Paul Lnrocquc, student, 795 Terrasse Laurentienne, 17, St.Foy, and Gilles Héon, archivist, 881 Lévis, Shawinigan, for the following purposes: To promote knowledge of history, under the name of \"Société Jeune Histoire Québec\".The amount to which the value of the immovable properlv which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 810,000.The head office of the corporation is at 881 Lévis St., Shawinigan, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32500 4911-69 Sol-Rose Investments Ltd.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la \\a>\\ des compagnies, le liciitenant-goiivc'-neur de la province a accorde des lettres palciitcs.en date du 23c jour dc septembre 1060, constituant en corporation: Saul Handelmaii, 5532, Rosedale, Côte Saint-Luc, Lilian Reinblatt.épouse dc Moc Reinblatt.4520, Rosedalc.Montréal, tous deux avocats, et Dorcen Manning, secrétaire, épouse de Claud Maiming.712, 31e Avenue.Lachinc, pour les objets suivants: Exploiter une compagnie de placement, sous 1>' nom de « Sol-Rose Investments Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,500 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de In compagnie est 197, chemin llarland, Hampstead, district judiciaire de Montréal./.c soiis-miiiislre des institutions financières, com]Hignies et coopératires, Ls-Philippe Bouchard.32506 4570-69 Sol-Kosc Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of September, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Saul Hundelmnn.5532 Roscdule.Cote Saint-Luc, Lilian Reinblatt, wife of Moe Reinblatt, 4520 Rosedalc, Montreal, both advocates, and Dorcen Manning, secretary, wife of Claud Manning.712, 31st Avenue, Laclline, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Sol-Rose Investments Ltd.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 5.000 common shares of 31 each and 3,500 preferred shares of 810 each.The head ollice of the company is at 197 llarland Road, Hampstead, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4570-69 Stationnement Fleur dc Lys inc.Avi.s est donné qu'en vertu de la première partie île la Ix)i des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province a accorde des lettres patente,, en date du 30e jour d'octobre 1969, constituant en corporation : Mortimer Chaikelson, 5893, Cluiiranald, Morris Chaikelson, 4950, Ponsard, tous deux avocats, de -Montréal, et Thérèse Perrcault, secrétaire, fille majeure.5533.Henri Bourassa est, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Exploiter des parcs dc stationnement, terrains, immeubles et bâtiments, sous le nom de « Stationnement Fleur de Lys inc.».avec un capital total oses: To operate parking lots, lands, real estate and buildings, under the name of \"Stationnement Fleur dc Lys inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each und 2.000 preferred shares of 810 euch. 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 I-o siège social de la compagnie est 1255.Carré Phillips, suite 1005.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlllUPPE Hoi chah n.32506-o 479Ô-C9 Studio Tempo inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première purtie de lu Loi des compugnies, le lieutcnunt-gouvornour de lu province u uccordé des lettres putentos, en dutc du Ce jour de novembre 1969, constituant en corporation: Yves Lupiorrc, 180, rue Floury ouest, liernurd Scott, 11574, rue Tanguay, tous doux dc Montréul, et Wuync Jones, 4949, dc Muisonncuvc, Westmount, tous trois artistes, pour les objets suivants: Effectuer en tout ou en purtie sur ruban sonore, disque, film ou ruban magnétoscopique des productions de nature commerciale, industrielle ou autre par les méthodes contemporaines et habituelles, sous le nom de < Studio Tempo inc.», avec un capital total de §40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires do 810 chacune et en 200 uctions privilégiées de 8100 chacune.1* siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire lie Montréul.Le sous-minislre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 2553-09 The heud office of the company is at 1255 Phillips Square, suite 1005, Montreal, judiciul district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Députa Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives.32500 4795-09 Studio Tempo inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of November, 1909, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Yves Lapierrc, 180 Floury Street West, Bernard Seott, 11574 Tanguay Street, both of Montreal, ami Wayne Jones, 4949 do Maisonncuve, Westmount, all three artists, for the following purposes: To carry on recordings on sound-ta|>e, record or film of all kinds of commercial or industrial productions by the usual methods, under the name of \"Studio Tempo inc.\", with a total capital stock of 840.000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head ollice of the company is at Montreal, judiciul district of Montreal.Ls-Puii.ii'i'k Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives.32500 2553-60 Super Marché Drolct inc.Avis est donné qu'en vertu de lu première purtie de In Ia>\\ dos compugnies, le lieutenant-gouvcnicur dc lu province u uccordé des lettres patentes, en date du Oe jour de novembre 1909, constituunt en corporation: André Morissctte.technicien en alimentation, 129, Carré Provence, Neufchatel, Donat Drolet, commis-épicier, te Eugène Drolet, aide-cuisinier, ces deux derniers de 2330, rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorotto, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers-bouchers licenciés, sous le nom dc « Super Marché Drolct inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 2330, rue Notre-Dame, L'Anciennc-Loretto, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératires, Ls-Phiuppe Bouchard.32506-o 4993-09 Super Marche Drolct inc.Notice is given that under Part I of tlie Compnnies Act, letters patent, bearing date the (itli day of November, 1909.have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: André Morissctte, technician in food products, 129 Provence Square, Neufchatel.Donat Drolet, grocer clerk, and Eugène Drolet.cook helper, the latter two of 2330 Notre-Dame Street, L'Ancienne-Lord to, for the following purposes: To carry on business as licensed grocers-butchers, under the name of \"Super Marché Drolct inc.\", with u total capital stock of 940,000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head oflicc of the company is at 233\" Notre-Dame Street, L'Ancionne-Lorotte, judicial district of Québec.Ls-Piiii.ii'i'k BouCHard, Deputy Minister of Financial Inslilnlions, Companies and Coopératires.32500 4908-60 Sutton Ski & Holiday Resort Inc.Centre de Ski et de Villégiature de Sutton inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur de la province 'a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1909, constituant en corporation: Marcel La font aine, avocat.Poule Lafontaine, étudiante en droit, tous deux dc 47, Courcelettc, Outremont, et Rachel Bouchard, secrétaire, 48, Robert, Suint-Basile-lc-Grand, ces deux dernières filles majeures, pour les objets suivants: L'aménagement et le développement de centres de ski et de villégiature, sous le nom dc « Sutton Ski & Holiday Resort Inc.\u2014 Centre dc Ski et dc Villégiature de Sutton inc.», avec un capital Sutton Ski & Holiday Resort Inc.Centre dc Ski et dc Villégiature dc Sutton inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Marcel Lafontaine, advocate, Paulc Lafontaine, law student, both of 47 Courcelettc, Outremont, and Rachel Bouchard, secretary, 48 Robert, Saint-Basilc-lc-Grand, the latter two spinsters of the full age of majorité, for the following purposes: The planning and development of ski and holiday resorts, under the name of \"Sutton Ski & Holiday Resort Inc.\u2014 Centre de Ski et de Villégiature de Sutton inc.\", with a total capital QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 53 total dc $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires «le $10 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 5795, avenue Decelles, app.10, Montréal, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératires, Ls-Philippe Bouchard.32500-u 5082-69 stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 5795 Decelles Avenue, Apt.10, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 5082-69 Swanslon fleuriste inc.Avis est donné qu'en vertu dc la première partie dc la Loi ration est situé à Montréal.Le sous-scerflaire dc lu province, Raymond 1)ou ville.32516-0 11-1969 To carry on the business of a real estate, construction, investment and management company, under the name of \"Wolfe Management Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,500 common shares of a par value of 81 euch and 375 preferred shares of a par value of 8100 each.The heud office of the company is at 2050 de Maisonncuve Boulevard, suite 202, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506-o 4912-69 St.Michuel's & St.Anthony's Catholic Community Notice is hereby given that pursuunt to the Roman Cntholic Bishops Act, Revised Statutes, 1964, chapter 304, the Lieutenant-Governor of the Province granted letters patent dated August 5, 1969, incorporating \"St.Michael's & St.Anthony's Catholic Community\".The head office of the corporation is situated in Montreal.Raymond Doiville, Assistant Secretary of the Province.32516 11-1969 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Cercle Universitaire (Québec) Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des compagnies, le lieutenant-gouverneur dc la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en dutc du 16c jour dc mai 1969, ù lu corporation * Cercle Universitaire (Québec) », 1° modifiant ses iiouvoirs; 2° augmentant le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que ih'iit acquérir et posséder ladite corporation de \u2022S500.000 ù 81,000,000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Rouenard.32506-c 2051-43 \u2014 1519-48 Chibougamau Lu ni her limitée Chibougamau Lumber Limited Avis est donné qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, le lieutenant -gouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 13e jour de novembre, 1969, ù la compagnie < Chibougamau Lumber limitée \u2014 Chibougamau Lumber Limited », étendant ses pouvoirs./1 sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.32506-o 6707-47 \u20141519-18 La Compagnie d'Aménagement Touristique de l'Est du Québec inc.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, le lieutcnant-Rouverneur de la province a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 7e jour de juillet 1969, il « La Compagnie d'Aménagement Touristique de l'Est du Québec inc.», 1° convertissant et subdivisant ses 400 actions ordinuires de 8100 chacune en 8,000 actions ordinaires Cercle Universitaire (Québec) Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of May, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Cercle Universitaire (Québec)\", 1.mollifying its powers; 2.increasing the amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold, from 8500,000 to 81,000,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 2051-43\u2014 1519-48 Chibougamau Lumber limitée Chibougamau Lumber Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 13th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"Chibougamau Lumber limitée \u2014 Chibougamau Lumber Limited\", extending its powers.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32506 6707-47 \u2014 1519-18 La Compagnie d'Aménagement Touristique de l'Est du Québec inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day of July, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province to \"La Compagnie d'Aménagement Touristique de l'Est du Québec inc.\", 1.converting and subdividing its 400 common shares of 8100 each into 8,000 common shares without par value; 58 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 janvier 1970, 102' année, u° 1 sans valeur uu pair; 2° augmentant son capital par la création ration « Centre Constance Lcthbridge \u2014 Constance Lcthhridgc Centre», et ce, en vertu de l'article 226 de la Loi des compagnies.Ix Kou.s-mini.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-P|iilii'i>e bouchard.32520-o 7045-45 Centre Constuncc Lcthbridge Constance Lcthbridge Centre Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Compaics and Cooperatives has, on December 9, 1969, approved by-law number \"C\" of \"(-'entre Constance Lcthbridge \u2014 Constance Lcthbridge (\"entre\", and such, pursuant to section 226 of the Companies Act.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy M inisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.32520 7045-45 Cleyn & Tinker, Ltd.Avis est donné que la compagnie « Cleyn & Tinker, Ltd.», a changé le nombre de ses administrateurs de 11 à 12.Le secrétaire, L.W.Neville.32521 13142-02 Cleyn & Tinker, Lid.Notice is given that \"Cleyn & Tinker, Ltd.\".has changed the number of its directors from 11 to 12.L.W.Neville, Secretary.32521-0 13142-62 Custom Kitchen and Slice! Metal Works Ltd.Avis est donné que lu compugnic « Custom Kitchen and Sheet Metal Works Ltd.», u chungé le nombre de ses administrateurs dc 3 à 4.Le président, Edmond Sblmeci.Custom Kitchen and Sheet Metal Works Ltd.Notice is given thut \"Custom Kitchen and Sheet Metal Works Ltd.\".bus changed the number of its directors from 3 to 4.Edmomd Sel.meci, President.32522 3827-64 32522-0 3827-01 Gestad inc.Avis est donné que lu compagnie « Gestad inc.», a changé le nombre de ses administrateurs dc 3 à 9.Le secrétaire, Andre Gai dette.32523-o 5100-66 Gestad inc.Notice is given that \"Gestad inc.\", lias cliangeil the number of its directors from 3 to 9.32523 André G au dette, Secretary.5100-00 Grace Dart Hospital Foundation Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives u, le 18 décembre 1909, approuvé le règlement numéro I dc lu corporation ¦ Grace Dart Hospitul Foundation », et ce, en vertu de l'article 226 de lu Loi des compugnies.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies el coopératires, Ls-PllILIPPE Bouchard.32524-0 5041-69 Grace Dart Hospital Foundation Notice is hereby given thut the Minister of Financial Institutions, Companies und Coopératives bus, on December 18, 1969, approved by.luw number 1 of \"Grace Dart Hospital Foundation\", und such, pursuant to section 226 of I lie ( Companies' Act.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératires.32524 5041-00 Greenfield Park Lumber and Builders Supplies Limited Avis est donné que la compagnie « Greenfield Park Lumber ami Builders Supplies Limited », a changé le nombre de ses administrateurs «le 5 à 3.Le secrétaire, Gaétan Chabot.32525-o 10295-56 Greenfield Park Lumber and Builders Supplies Limited Notice is hereby given that \"(ireenfichl Park Lumber and Builders Supplies Limited\", has changed the number of its directors from 5 to 32525 Gaétan Chabot, Secretary.10205-56 J.Reginald Grondin inc.Avis est donné que la compagnie « .1.Reginald Grondin inc.», a changé le nombre «le ses administratcur- dc 3 ù 5.Le secrétaire, André Grondin.32526-0 4647-63 J.Reginald Grondin inc.Notice is given that \".I.Reginald Grondin inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 5.André Grondin.Secretary, 32526 4647-03 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 89 The .Mental Hygiene Institute Inc.Avis est donné que « The Mental Hygiene Institute Inc.» a changé le nombre de ses administrateurs dc 18 ù 24.Le secretaire, Robert I.Cowuno.112527 101-30 The Mental Hygiene Institute Inc.Notice is given that \"The Mental Hygiene Institute Inc.\" has changed the number of its directors from 18 to 24.Robert .1.Cowling, Secretary.32527-0 101-30 Merchants1 Overseas Corporation Avis est donné que « Merchants' Overseas Corporation » a changé le nombre de ses administrateurs dc 5 ù 3.Le secrétaire, Marc Masson Bienvenu.32528 3912-08 Merchants' Overseas Corporation Notice is given that \"Merchants' Overseas Corporation\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Marc Masson Bienvenu, Secretary.32528-o 3912-68 I.c s Placements d'Auteuil inc.Avis est donné que la compagnie « Les Placements d'Auteuil inc.» a changé le nombre dc ses administrateurs de 6 à 3.Le secrétaire, Yves Demers.32529-0 14030-62 Les Placements d'Auteuil inc.Notice is hereby given that \"Les Placements d'Auteuil inc.\", has changed the number of is directors from 6 to 3.Yves Demehs, Secretary.32529 14030-62 Pollack's Ltd.Pollack's Ltd.Avis est donné que « Pollack's Ltd.» a changé Notice is given that \"Pollack's Ltd.\" has le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.changed the number of its directors from 4 to 3.L'assistant-secrélaire, Claire L'Heureux Dubé, Claire L'Heureux Dubé.Assistant-Secretary.32530 2095-51 32530-o 2095-51 Maurice Pollack Realty Company Limited Avis est donné que « Maurice Pollack Realty ( 'oinpany Limited » a changé le nombre de ses administrateurs dc 4 à 3.L'a ssislan I- secrétaire.Claire L'Heureux Dubé.32531 243-29 Maurice Pollack Really Company Limited Notice is given that \"Maurice Polluck Realty Company Limited\" lias chunged the number of its directors frmo 4 to 3.Claire L'Heureux Dure, Assistant-Secretary.3253 l-o 243-29 I'nllack Properties i(Trois-Rivicres) Limited Les I m me 11 Id: :s Pollack (Trois-Rivières) limitée Avis est donné que « Polluck Properties (Trois-Rivières) Limited \u2014 Les Immeubles Polluck 1 Trois-Rivières) limitée » u changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.L'assislaitt-secrétairc, Claire I?Heureux Dubé.32532 150-06 Pollack Properties (Trois-Rivières) Limited Les Immeubles Polluck (Trois-Rivières) limitée Notice is given that \"Pollack Properties (Trois-Rivières) Limited \u2014 Ix-s Immeubles Pollack (Trois-Rivières) limitée\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Claire L'Heureux Dubé, Assistant-Secretary.32532 150-66 Suitmastcr Inc.Avis est donné que « Soil master Inc.» a changé le nombre dc ses administrateurs dc 3 à 4.Le secrétaire.Sonny Meruit.32533 3278-67 Suitmastcr Inc.Notice is given that \"Suitmastcr Inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Sonny Meruit, Secretary.32533-0 3278-67 Voyages Granby, inc.Avis est donné que lu compagnie « Voyages tiranby, inc.» a changé le nombre de ses administrateurs de 3 a 4.Le secrétaire, Pierrette West.32534-0 5699-65 Voyages Granhy, inc.Notice is hereby given that \"Voyages Granby, inc.\", has changed the number of its directors from 3 to 4.Pierrette West, Secretary.32534 5699-65 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, «° 1 Mont-Lebcl Le soussigné donne avis que, tel que demandé dans une résolution passée le 1er décembre 1960 par le conseil municipal dc Mont-Lebcl, comté de Rimouski, et conformément aux dispositions de l'article 130 du Code municipal, il a décrété, en date du 17 décembre 1969, cpie les publications de tous les avis publics, règlements, résolutions ou ordres de la corporation dc Mont-Lebcl, comté de Rimouski, sauf celles requises dans la Gazelle officielle du Québec, se feront, à l'avenir, dans la langue française seulement.I.c présent avis est publié en vertu dc l'article 131 «lu Code municipal.Québec, le 17 décembre 1969.lœ sous-ministre des affaires municipales, 32540c Richard Beailieu.Mon l-l.i bel The undersigned gives notice that, as requested in a resolution passed on December 1, 1969 by the municipal council of Mont-I.ebel, county of Rimouski, and pursuant to the provisions of section 130 of the municipal Code, he decreed, on December 17, 1969, that the publication of all public notices, by-laws, resolutions or orders of the corporation of Mont-Lebel, county of Rimouski, save those required in the Quebec Official Gazelle, shall be made, henceforth, in the French language only.This notice is published under section 131 ol the Municipal Code.Québec, December 17, 1969.Richard Bbaulieu, 32540 Deputy Mini.slcr of Municipal .1 {fairs.Demande à la Legislature Application to Legislature The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada Avis est par les présentes donné que « The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada», s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, à sa prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi aux fins dc changer son nom en celui de « St-Nicholas Antiochian Orthodox Church \u2014 L'Église orthodoxe St-Nicholas d'An-tiochc », et aux fins dc modifier ses pouvoirs.Montréal, ce 8e jour dc décembre 1969.Les procureurs des pétitionnaires, Blain, Piché, Bergeron, Godbovt, Emery 32335-51-4-0 Blain & Vallerand.The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada Notice is hereby given that \"The Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Canada\", will apply to the National Assembly of Québec, at its next session, to seek the ndoption of a Bill changing its name to \"St-Nicholas Antiochian Orthodox Church \u2014 L'Église Orthodoxe St-Nicholas d'Antioche\", and modifying its powers.Montreal, December 8th, 1969.Blain, Piché, Bergeron, Goddout, Emery, Blain & Vallerand, 32335-51-4-0 Solicitors for the Petitioners.Ministère de l'Education Department of Education Scclcur-Vicloriuvillc Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires ville d'Arthabaska, Sain t-Paul-de-C lies ter, Saint-Valèrc, Victoriavillc, dans le comté d'Arthabaska, et Massa-biellc, dans le comté de Wolfe, et dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Secteur-Victoriavillc, dans les comtés d'Arthabaska et Wolfe.Québec, le 17 décembre 1909./.c ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.32404-52-2-o 010-01 Secteur-Victoria ville Application is made to amalgamate the prcsctil territories of the school municipalities of Ville d'Arthabaska, Saint-Paul-de-Chestcr, Saint-Valc-rc, Victoriavillc, in the county of Arthabaska, and Mu-ssabielle.in the county of Wolfe, and I\" erect it into a new school municipality under the name of Secteur-Victoriavillc, in the Counties of Arthabaska and Wolfe.Québec, December 17, 1909.Jean-Guy Cardinal, Minister of Education.32464-52-2 OKM'l Secteur- Warwick Demande est faite de fusionner le territoire actuel des municipalités scolaires de Chénicr, Saint-Albert, Saintc-Clotilde-dc-IIorton.Saintc-Elisabeth-dc-Warwick, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saintc-Séraphine et Warwick, dans le comté d'Arthabaska, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom de Scctcur-Warwick, dans le comté d'Arthabaska.Québec, le 17 novembre 1969.Ix ministre de l'Education, .1e an-( i l'y Car din al.32465-52-2-0 010-04 Secteur-Warwick Application is made to amalgamate the present territory of the school municipalities of Cliénier.Saint-Albert, Sainlc-CIotilde-de-IIorton.Sainte-Élisabctli-de-Warwick, Saint-Rémi-de-Tingwick, Saintc-Séraphine and Warwick, in the county of Arthabaska, and to erect it into a new school municipality under the name of Scctcur-Warwick, in the county of Arthabaska.Québec, November 17, 1969.Jean-Guy Cardinal.1/inisler of Education.32465-52-2 OKI-\" I Ministère des Department of Affaires municipales Municipal Affairs QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 71 Acton Vale Demande est fuite do fusionner le territoire actuel îles municipalités scolaires d'Acton Vale, Sainte-Christine (paroisse), dans le comté de Bagot, et Saint-Fulgcncc No 1 (culli.) dans le comté de Drummond, et dc l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire sous le nom d'Acton Vide, dans les comtés dc lingot et Drummond.Québec, le 17 décembre 1969.Ijs ministre de l'Education, Jean-Guy Cardinal.32406-52-2-o 6S0-O2 Acton Vale Application is made to amalgamate the present territory of the school municipalities of Acton Vale, Sainte-Christine (parish) in the county of Bagot, and Saint-Fulgcncc No.1 (ruth.) in the county of Driiinmond, and to erect it into a new school municipality under the name of Acton Vale in the counties of liugol ami Drummond.Québec, December 17, 1009.JeAN-G u y G All DINAL, M inisler of Education.324GC-52-2 630-02 Siège social Centre Conslunee Lcllibridgc Centre Avis est par les présentes donné que * Centre Constance Lcthhridgc Centre ¦', une corporation constituée en vertu de la troisième partie de lu Loi des compagnies, par lettres patentes datées du G décembre 1945, sous le nom dc « Occupational Therapy and Rehabilitation Centre», a changé son siège social dc 1031, rue Ottawa, en In ville de Montréal à 7005 ouest, boulevard dc Maisonncuve.en ladite ville dc Montréal.Montréal, 2 septembre 1969.(Sceau) Le .secrétaire honoraire, Elinor Bahnstead.32520 7045-45 Head Office Centre Constance Lclhhridgc Centre Notice is hereby given that \"Centre Constance Lcthhridgc Centre\", incorporated under l'art III of the Companies Act by letters patent dated December 0, 1915 under the name of \"Occupational Therapy and Rehabilitation Centre\", has changed its head ollice from 1031 Ottawa Street in the city of Montreal to 7005 de Maisonncuve Boulevard West, in the said city of Montreal.Montreal, September 2, I960.(Seal) Elinor Bahnstead, llonoruri/ Secretary.32520-o 7045-45 ( '.hangement de nom \u2014 Loi du Jean Pierre Camille Désire André dit Drean Avis est par les présentes donné, que Jean Pierre Camille Désiré André dit Drcan, publicise, domicilié et résidant à 727 rue Ritchie, Ville Jacques Cartier, Province dc Québec, transmettra au Secrétaire dc la Province dc Québec, une requête demnndnnt que son nom soit changé dc Jean Pierre Camille Désiré André en celui de Jean Pierre Camille Désiré Drean, et que ce changement dc nom bénéficie à sa fille et ù ses enfants à naître.Montréal, le 17 décembre 1969.Les procureurs du requérant, Desciiênes, De Grandpré, Colas, 32498-52-2-0 Godin & Lapointe.Joseph Nicol Parent Avis est donné par ces présentes que Joseph Nicol Parent résidant et domicilié au numéro 189, boulevard Sacré-Coeur, en la ville et district dc Rimouski, présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil, sous la Loi du changement dc nom, demandant un changement dc son nom en Joseph-Marc Parent.Les procureurs du requérant, Casgrain, Casgrain 32499-52-2-0 & Crevieh.Joseph Lucien Jean Paul Fournier H a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4156, du 17 décembre 1969.'I effectuer le changement «le nom de Joseph Lucien Jean-Paul Morin en celui de Joseph Lucien Jeun Paul Fournier.Québec, h- 23 décembre 1969.Le sous-secrétaire de la province, 32538-o Raymond Douville.Change of name \u2014 Act Jean Pierre Camille Désiré André dit Drean Notice is hereby given that Jean Pierre Camille Désiré André dit Drcan, residing at 727 Ritchie Street, in the city of Ville Jacques Cartier, Province of Québec, will transmit to the Secretary of the Province of Québec, un implication to modify his name from Jean Pierre Camille Désiré André, to Jean Pierre Cnmille Désiré Drcan, and that the said modification shall benefit to his daughter and to his children to be born.Montreal, December 17, 1969.Desciiênes, De Grandpré, Colas, Godin & Lapointe, 32498-52-2-0 Attorneys of the petitioner.Joseph Nicol Parent Notice is hereby given that Joseph Nicol Parent, residing at 189, Sacré-Coeur Boulevard in the city and district of Rimouski, will make application to the Lieutenant-Governor in Council, requesting an order chunging his name to that of Joseph Mure Parent.Casgrain, Casgrain & Crevier, 32499-52-2-0 Attorneys for the applicant.Joseph Lucien Jean Pu til Fournier The Lieutenant-Governor in Council bus been pleased by decree Number 4156.dated December 17, 1909, to effect the change of name of Joseph Lucien Jean-Paul Morin into that of Joseph Lucien Jean Paul Fournier.Québec.December 23.1969.Raymond Dot ville, 32538 Assi-lanl Secretary of the Produce. 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 Lynda Carroll Brown Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4158.du 17 décembre I960, d'effectuer le changement de nom de Linda Carol Field en celui de Lynda Carroll Brown.Québec, le 23 décembre 1969.Le sous-secrétaire de la produce, 32538-0 Raymond Doivii.lk.Joseph Laurent Arnold Moisan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4159, du 17 décembre 1969, d'effectuer le changement dc nom de Joseph Laurent Arnold en celui dc Joseph Laurent Arnold Moisan.Québec, le 23 décembre 1969.Le sous-secrétaire dc la produce.32538-0 Raymond Dot vii.i.k.Albert Rafla Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4157, du 17 décembre 1969.d'effectuer le changement de nom dc Albert Rafla Abdcl-Malck en celui de Albert Rafla.Québec, le 23 décembre I960.Le sous-secrétaire dc la produce.32538-0 Raymond Dor vii.i.k.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre Avis dc prélèvement L'honorable Maurice Bcllemare, ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, donne avis par les présentes que le Comité paritaire des Coiffeurs île Trois-Rivières, établi en exécution du décret numéro 3010 du 18 septembre 1968, a été autorisé par règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 4057 du 17 décembre 1969, le tout d'accord avec les dispositions dc la Loi des décrets de convention collective (Statuts refondus of 1% of the sidury set forth in the decree for the lowest-paid journeyman (50c a week) or of the average salary set by the Committee.(c) Employees governed by said Decree number 3010 shull turn over to the Parity Committee an amount equivalent to Yi of 1' < of their earnings (fixed salaries, percentages, commissions, allowances or bonuses).2.Collection of dues To facilitate the collection of such dues, the Parity Committee supplies professa ma I employers with report forms on which all the information QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 73 port sur lesquelles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.I,'employeur professionnel doit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité paritaire à chaque mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin de chaque semaine, au nom du Comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire dc ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le lOièmc jour du mois suivant la date d'expiration dc la période pour laquelle il est exigible; ledit rapport doit être accompagné dc la cotisation de l'employeur professionnel et des sommes payables au Comité paritaire par ses salariés.Le ( 'omité u le pouvoir d'exiger l'assermentation dudit rapport chaque fois qu'il le juge à propos.Le prélèvement imposé par le présent règlement est payable mensuellement par l'employeur professionnel, l'artisan et le salarié, sans mise en demeure au préalable.Sur refus d'un employeur professionnel ou d'un artisans de payer ses cotisations ou de donner les renseignements nécessaires, un avis de cinq (5) jours lui sera donné pour remplir ses obligations envers le comité paritaire.3./{a pporl fui a n cicr D'accord avec les dispositions de la Loi des décrets de convention collective, le Comité paritaire doit présenter un rapport trimestriel de ses opérations financières au ministre du Travail el de la Main-d'ocuvrc, aux dates fixes suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.Ci-annexé, un état des revenus el dépenses prévus du Comité paritaire des Coiffeurs dc Trois-Rivières, i>our la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970.Comité paritaire des coiffeurs de Trois-Rivières État îles revenus cl dé'ienses probables jxjur la |)ériodc comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970.Retenue: Cotisations patronales.8 1,414.00 Cotisations ouvrières.1,414.00 < Cotisations artisanales.13,364.00 Pénalités et amendes.400.00 Ilonoraires d'examens.725.00 < ours de formation.120.00 $17,437,00 Dépeintes: Salaire du secrétaire.8 3,900.00 Salaires du personnel.3,120.00 frais d'inspection.2,600.00 Honoraires: Bureau des examinateurs 725.00 Loyer et taxes.1,020.00 Kclairage, chauffage, entretien.100.00 frais judiciaires.800.00 frais de vérification.260.00 I inprcssion, papeterie, ucc.dc bureuu 500.00 Poste, téléphone, télégramme.475.00 Intérêt, échange, agios.85.00 Abonnement et publicité.250.00 ¦liions «le 1% de leur liste de paye pour les salariés assujettis audit décret (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis payés).h) Les artisans régis par ledit, décret numéro 3132, doivent verser au Comité paritaire une somme équivalente à de 1% du salaire établi dans le «h'-cret pour le compagnon le moins rémunéré.c) Les salariés r«'-gis par ledit décret numéro 3132, doivent verser nu Comité paritaire une somme équivalente à }j «le 1% «le leur rémunération (salaires fixes, pourcentages, commissions, allocations ou bonis).2.Mode de perception Eu vue dc faciliter la perception «le ces cotisations, le Comité paritaire met à la disposition des employeurs professionnels «les formules «le rapport sur les«|uclles doivent être indiqués tous les renseignements exigés par ledit Comité paritaire.L'employeur professionnel «loit compléter son rapport, le signer et le faire parvenir au Comité à chatpic mois.L'employeur professionnel doit percevoir, à la fin dc chaque semaine, nu nom du comité, le prélèvement imposé à ses salariés, au moyen d'une retenue sur le salaire dc ces derniers.L'employeur professionnel doit transmettre son rapport mensuel au Comité paritaire le ou avant le 15 du mois suivant la date d'expiration de la période ]K>ur laquelle il est exigible; ledit rapport «loit être accompagné de la cotisation dc .Notice of Levy Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (HSQ 1964.c.143).the Honourable Maurice licllemarc.Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice thai the Construction Industry Parity Committee of the Region of Montréal (established in pursuance of Decree number 3132 of October 22nd, I960) bus been authorized to levy «lues on the profcs-lional employers, artisans ami employees subject to the saiil decree, according to the conditions mentioned below.A by-law, approved by Order in Council number 4056, dated December 17.I960, authorizes such levy.1.Dues The con tribut ion period extends from January 1st.1970 to April 30th, 1970.The levy is carried out as follows: (a) Professional employers governed by said Decree number 3132 shall pay the Parity Committee an amount equivalent to }¦> of 1% of their payroll for the employees subject to the said Decree (fixcil salaries, percentages, commissions, allowances or bonuses paid).(/ of 1% of the salary set forth in the decree for the lowest-paid journeyman.(c) Employees governed by said Decree number 3132 shall turn over to the Parity Committee an amount equivalent to ,'\u2022> of 1% «if their wages (fixed salaries, percentages, commissions, allowances or bonuses).2.Collection of Dues To facilitate the collection of such dues, the Parity Committee supplies the professional employers with report forms on which all the information requested by the said Parity Committee must be given.Every month, the professional employer shall complete, sign and forward his report to the Committee.At the end of each week and on the Committee's behalf, the professional employer shall collect this levy by means of a check-off.The professional employer shall forward his monthly report to the Parity Committee on or before the 15th of the month following the expiry date of the period for which it is required.The professional employer's dues together with QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1070, Vol.102, No.1 75 l'employeur professionnel et seront reçues par le soussigné Emile Daoust, greffier, Hôtel dc Ville, 1800, boulevard Saint-Joseph, Lachine, comté de Jucques-Cnrtier, P.Q., jusqu'il 8 heures du soir, lundi, le 19 janvier 1970, pour l'achat de $1,225,-000 dc la cité dc Lachine, comté de Jacques-Cartier, datées du 31 décembre 1969 et remboursables par séries du 31 décembre 1970 au 31 décembre 1989 inclusivement, avec intérêt il un taux non inférieur à 8%, ni supérieur ù 9%, payable semi-annuellemcnt les 31 juin et 31 décembre de chaque année Le taux d'intérêt peut Tenders City of Lachine County of Jacques-Cartier Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Emile Daoust, City Clerk, City Hall, 1800 Saint-Joseph Boulevard, Lachine, county of Jacques-Cartier, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Monday, January 19, 1970, for the purchase of an issue of $1,225,000 of bonds of the city of Lachine, county of Jacques-Cartier, dated December 31,1969 and redeemable serially from December 31, 1970 to December 31, 1989 inclusively, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on June 31st and December 31st each year.The rate of interest may be the same for 78 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlements numéros: 187S tel que modifie \u2014 8193,000 \u2014 aqueduc, égouts; 1889 \u2014 $50,000 \u2014 voirie, etc.; 1892 \u2014 S140.000 \u2014 aqueduc, égouts; 1896 \u2014 845,000 \u2014 aqueduc, égouts; 1903 \u2014 S28.000 \u2014 voirie; 1900 \u2014 S103.000 \u2014 voirie; 1914 \u2014 86,000 \u2014 aqueduc, égouts; 1922 \u2014 S200.000 \u2014 voirie; 1929 \u2014 S12.000 \u2014 éclairage; 1930 \u2014 S8.000 \u2014 éclairage; 1931 \u2014 836,000 \u2014 éclairage; 1932 \u2014 $7,000 \u2014 éclairage; 1933 \u2014 $6,000 \u2014 éclairage; 1934 \u2014 SS.000 \u2014 éclairage; 1935 \u2014 $6,000 \u2014 éclairage; 1930 \u2014 S17.000 \u2014 éclairage; 1937 \u2014 S7.000 \u2014 éclairage; 1938 \u2014 $90,000 \u2014 voirie, éclairage; 1940 \u2014 $77,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc; 1945 \u2014 $180,000 \u2014 services récréatifs et communautaires.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 31 décembre 1909.the whole issue; however, should more than one rale be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption of this notice.By-laws numbers: 1878 ns amended \u2014 S193.000 \u2014 aqueduct, sewers; 1889 \u2014 $50,000 \u2014 roads, etc.; 1892 \u2014 S140.000 \u2014 aqueduct, sewers; 1896 \u2014 $45,000 \u2014 aqueduct, sewers; 1903 \u2014 $28,000 \u2014 roads; 1906 \u2014 $103,000 \u2014 roads; 1914 \u2014 $6,000 \u2014 aqueduct, sewers; 1922 \u2014 $200,000 \u2014 roads; 1929 \u2014 S12.000 \u2014 lighting; 1930 \u2014 $8,000 \u2014 lighting; 1931 \u2014 $36,000 \u2014 lighting: 1932 \u2014 $7,000 \u2014 lighting; 1933 \u2014 $6.000 \u2014 lighting; 1934 \u2014 SS.000 \u2014 lighting: 1935 \u2014 86,000 \u2014 lighting; 1936 \u2014 $17,000 \u2014 lighting; 1937 \u2014 $7,000 \u2014 lighting; 1938 \u2014 $96,000 \u2014 roads, lighting; 1940 \u2014 $77,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 1945 \u2014 $180,000 \u2014 recreational and community services.For adjudication only, interest shall be calculated as from December 31, 1969.Tableau d'amortissement \u2014 SI,225,000 \u2014 20 ans Année Capital 31 décembre 1970.$ 28,000 31 décembre 1971.31,000 31 décembre 1972 .33,000 31 décembre 1973 .35,000 31 décembre 1974.38,000 31 décembre 1975 .41,000 31 décembre 1976 .43,000 31 décembre 1977.47,000 31 décembre 1978.50,000 31 décembre 1979.54,000 31 décembre 1980.58,000 31 décembre 1981.63,000 31 décembre 1982 .67,000 31 décembre 1983.$ 73,000 31 décembre 1984 .78,000 31 décembre 1985.84,000 31 décembre 1986 .90,000 31 décembre 1987 .90,000 31 décembre 1988.104,000 31 décembre 1989.112,000 Table of redemption \u2014 $1,225,000 \u2014 20 years Year Capital December 31, 1970.S 28,000 December 31, 1971.31,000 December 31, 1972.33,000 December 31, 1973 .35,000 December 31, 1974 .38,000 December 31, 1975 .41,000 December 31, 1976 .43,000 December 31, 1977.47,000 December 31, 1978 .50,000 December 31, 1979 .54,000 December 31, 1980 .58,000 December 31, 1981.63,000 December 31, 1982 .67,000 December 31, 1983.$ 73,000 December 31, 1984.78,000 December 31, 1985 .84,000 1 )cccmbcr 31, 1986.90,000 December 31, 1987 .96,000 December 31, 1988.104,000 December 31, 1989.112,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à ternie fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans les cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $112,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans ne de- Moreovcr, the following terms and conditions only shall be considered : (1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance ns 20-year fixed-term bonds; (3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds; (4) Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part; (5) Ten-year serial bonds with the balance ns 5-year short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part; (6) Five-year short-term serial bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, as far as paragraphs (4), (5) and (6) arc concerned, the 20-year fixed-term bonds should be for an amount of not less than $112,000, and if greater than the latter amount, said part should include one only or several complete annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice and starting by the last years of maturities.Also, the 5-ycar or 10-ycar short term bonds shall include complete annual amortizations only, and starting QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January .3.11)70, Vol.102, No.1 79 vronl comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des except ion- notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Lachine.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ninsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.I,csdites obligations ne seront pas ruchctablcs par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à 5112,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans |>our un montant supérieur à SI 12,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 31 décembre dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément nu tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 19 janvier 1970, à S heures du soir, Hôtel de Ville, 1S00, boulevard Saint-Joseph, Lachine, comté dc Jacques-Cartier, 1\\Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lachine (Comté dc Jacques-Cartier), ce 10 décembre 1909.Le greffier, Emile Daoust.Hotel de Ville, 1800.boulevurd Saint-Joseph, Lachine (Comté dc Jacques-Cartier), P.Q.Téléphone : 037-4111, code 514.32452-0 Ville dc Disraeli Comté de Wolfe Avis public est pur les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations» seront reçues pur le soussigné André Rodrigue, .secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 550, rue Jacques-Cartier, Case postale 370, Disraeli, comté de Wolfe, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 21 janvier 1970, pour l'achat de $04,000 d'obligations de la ville de Disraeli, comté de Wolfe, datées du 1er février 1970 et remboursables pur séries du 1er février 1971 uu 1er février 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur ù 9%, pnyuble semi-unnucllemenl les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés uu tableau d'amortissement duns le présent avis.Règlement numéro: 192 tel que modifié \u2014 S94.000 \u2014 aqueduc, égouts.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1970.with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term pnrt.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exceptions stipulated above.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Lachine.Capital and interest arc payable at ull brunches in the Province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure as well as at the head office of said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and as 20-ycar fixed-term bonds for an amount equal to 8112,000.However, should they be issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than SI 12,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on December 31st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, January 19, 1970, at S:00 o'clock p.m., at the City Hall, 1800 Saint-Joseph Roulcvurd, La-chine, county of Jacques-Cartier, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Lachine (County of Jucqucs-Cnrtier), December 10, 1909.Emile Daoust, City Clerk.City Hall, 1S0O Saint-Joseph Boulevard, Lachine (County of Jacques-Cartier), P.Q.Telephone: 037-4411, code 514.32452 Town of Disraeli County of Wolfe Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned André Rodrigue, Secretary-Treasurer, Town Hull, 550 Jacques-Cartier Street, Post Ollice Box 370, Disraeli, county of Wolfe, P.Q., until S o'clock, p.m., Wednesday, January 21, 1970, for the purchase of an issue of 894,000 of bonds for the town of Disraeli, county of Wolfe, dated February 1, 1970 and redeemable serially from February 1, 1971 to February 1,1990 inclusively, with interest al a rate not less than 8%, nor more than 9%, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however if more than one rate is used, the amount issued at euch different rule must cover one or several whole annual amortizations, such as shown on the table of redemption in the present notice.By-law number: 192 such as amended \u2014 S94.000 \u2014 aqueduct, sewers.For adjudication only, interest shall be calculated as from February 1, 1970. 80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n° 1 Tableau d'amortissement\u2014$94,000 \u2014 20 ans Année\tCapital 1er février 1971.\t.82,000 1er février 1972.\t.2,500 \t.2,500 1er février 1974.\t.2,500 1er février 1975.\t.3,000 1er février 1970.\t.3.000 \t 1er février 1978.\t.3,500 1er février 1979.\t.4,000 1er février 1980.\t.4,000 1er février 1981.\t.4,500 1er février 1982.\t.5,000 1er février 1983.\t.5,000 1er février 1984.\t.5.500 1er février 1985.\t.6,000 1er février 1986.\t.6.500 1er février 1987.\t.7,000 \t 1er février 1989.\t.8.000 1er février 1990.\t.8.500 Fn plus, les modalité» suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 uns.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 uns pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 0°, les obligations échéant ù terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 88,500 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises ii courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuel- entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les eus des exceptions notées.L'adjudication sera fuite conformément à lu loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Disraeli.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesditcs obligations ne seront pas rachctables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à 88,500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $8,500 les obligations ainsi émises seront rachctables par anticipation au pair, le 1er février de chaque année pour le montant annuel Table of redemption \u2014 994000 \u2014 20 years Year Capital February 1, 1971.$2,000 February 1, 1972.2,500 February 1, 1973.2,500 February 1, 1974 .2,500 February 1, 1975.3,000 February 1, 1976 .3,000 February 1, 1977 .3,500 February 1, 1978.3,500 February 1, 1979 .4,000 February 1, 1980.4,000 February 1, 1981.4,500 February 1, 1982 .5,000 February 1, 1983.5,000 February 1, 1984 .5,500 February 1, 1985.0,000 February 1, 1986.6,500 February 1, 1987.7,000 February 1, 1988.7,500 February 1.1989 .8,000 February 1, 1990.8,500 In addition, only the following conditions shall be considered: 1.Bonds maturing serially with 5 year, 10-year or 15-year short-term.2.Bonds maturing serially 10-years with the balance as 20-year fixed-term.3.Bonds maturing serially 10-yeurs with the balance us 5-yeur short-term.4.Bonds maturing serially 10-years with the balance 10-year for one part and the other part as 20-year fixed-term.5.Bonds maturing seriully 10-years with Unbalance as 5-year short-term for one part and the other part as 20-year fixed-term.0.Bonds maturing seriully with 5-year short-term for one purt und the other part as 20-year fixed-term.However, in the cases of paragraphs 4, 5 and 6, the bonds maturing as 20-year fixed-term must not be for an amount inferior to $8,500 and if higher than this latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice, anil starting by the lust years of maturities.Also, tenders issued us 5-year or 10-yeur short-term, must include only whole annual umorti/.utions, und starting by the last yean of maturities excluding the purt ut 20-year fixed-term.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exception stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Disraeli.(Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term for an amount equal to $8,500.However, if they are issued partly for 20-ycar fixed-term for an amount greater than $8,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on February 1st of each year, for the annual amount required to amortize the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1070, Vol.102, No.1 81 requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 21 janvier 1970, ù 8 heures du soir, llôlcl dc ville, 550, rue Jacques-Cartier, Case postale 370, Disraeli, comté dc Wolfe, P.Q.l,c conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Disraeli (Comté de Wolfe), ce 19 décembre 1909./.c secrétaire-trésorier, André Rodrigue.1 Iôtel de ville, 550, rue Jacques-Curlier, Case postale 370, Disraeli, Comté dc Wolfe, P.Q.Téléphone: 449-2771, code 418.32535-0 issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the lender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to he held on Wednesday, January 21, 1970, at 8:00 o'clock, p.m., at the Town Hull, 550 Jacques-Cartier Street, Post Ollice Box 370, Disraeli, county of Wolfe, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Disraeli (County of Wolfe), December 19, 1969.André Rodrigue, Secretary-Treasurer.Town Hall, 550 Jacques-Cartier Street, Post Ollice Box 370, Disraeli, County of Wolfe, P.Q.Telephone : 449-2771, code 418.32535 Ville de Douvllle Comté dc St-Hyacinlhc Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Dominique Dupont, Hôtel dc ville, 1110, rue Chaplcau, Douville, comté dc Saint-Hyacinthe, P.Q., jusqu'à 9 heures du soir, lundi, le 19 janvier 1970, pour l'achat de SI 36,000 d'obligations dc lu ville de Douville, comté de Saint-Hyacinthe, datées du 1er février 1970 et remboursables pur séries du 1er février 1971 uu 1er février 1990 inclusivement, avec intérêt ù un laux non inférieur à 8%, ni supérieur ù 9% payublc semi-unnucllement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement numéro: 111 \u2014 8130,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1970.Town of Douville County of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Dominique Dupont, Town Hall, 610 Chaplcau St., Douville, county of Saint Hyacinthe, P.Q.until 9:00 o'clock p.m., Monday, January 19, 1970, for the purchase of an issue of 8136,000 of bonds for the town of Douville, county of Saint Hyacinthe, dated February 1, 1970, and redeemable serially from February 1, 1971 to February 1.1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8%, nor more than 9%, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-law number 111 \u2014 8136,000 \u2014 aqueduct, sewers, rouds.For adjudication only, interest will Ik- calculated as from February 1, 1970.Tableau d'amortissement \u2014 513(1,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er février 1971.S 3,000 1er février 1972 .3,500 1er février 1973 .3,500 1er février 1974 .4,000 1er février 1975 .4,000 1er février 1976 .4,500 1er février 1977.5,000 1er février 1978 .5,000 1er février 1979 .5,500 1er février 19S0.5,500 1er février 1981.6,000 1er février 1982 .7,000 1er février 1983 .7,500 1er février 1984 .8,000 1er février 1985 .8,500 1er février 1986.9,500 1er février 1987.10,000 1er février 1988.11,000 1er février 1989.12,000 1er février 1990.13,000 Table of redemption \u2014 $130,000 \u2014 20 years Year Capital February 1.1971.S 3,000 February I, 1972 .3,500 February 1, 1973 .3,500 February 1, 1974 .4,000 February 1,1975 .4,000 February 1, 1976.4,500 February 1, 1977 .5,000 Fcbmary 1, 1978 .5,000 Fcbniary 1, 1979 .5,500 February 1, 1980 .5,500 February 1.1981.6,000 February 1,1982 .7,000 February 1, 1983 .7,500 February 1, 1984.8.000 February 1, 1985.S.500 February 1, 1986.9,500 February 1, 19S7.10,000 February 1, 1988.11,000 February 1, 1989.12,000 Fcbniary 1, 1990.1 13,000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n' 1 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant eu séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 uns ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 uns avec le solde ù ternie fixe 20 uns.3° Obligations échéant en séries 10 uns avec le solde à courte échéance 5 ans.4 Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 uns avec le solde à courte échéance 5 ans |>our une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 ans.0° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 0°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S13.000, et si supérieur à ce dernier montant, cette purtie devra comprendre qu'un ou des umortis-sements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant |>ar les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que |x»ur uu seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Saint-Hyacinthe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans lu province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.I/Csditcs obligations ne seront pas rachctables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal à $13,000.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supé-rieur à $13,000, les obligations ainsi émises seront rachctables par anticipation, au pair, le 1er février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément au tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 19 junvicr 1970, à 9 heures du soir, Hôtel dc ville, 010, rue Chapleau, Douville, comté dc Saint-Hyacinthe, P.Q.Ix; conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Douville (Comté dc Saint-Hyacithc), ce 9 décembre 1969./,e secrétaire-trésorier, Dominique Dupont.Hôtel de Ville, 610, rue Chapleau, Douville, Comté dc Saint-Hyacinthe, P.Q., Téléphone: 774-4655, code 514.32536-o Moreover, only the following methods shall be considered: 1.Ponds maturing seriully with 5-yeur, 10-year or 15-ycar short-term.2.Bonds maturing in 10-year series with the balance for 20-year fixed-term.3.Bonds maturing in 10-ycar scries with Unbalance for 5-year short-term.4.Bonds maturing in 10-year series with Unbalance partly for 10-year short-term and partly for 20-ycar fixed-term.5.Bonds maturing in 10-year series with Unbalance partly for 5-year short-term and partly for 20-year fixed-term.6.Bonds mai u nil!; serially with 5-ycar short-term for the one part and 20-year fixed-term for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6.the bonds maturing at 20-year fixed-term shall not be for an amount less than 813,000, and, if higher than the latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice and starting by the last years of maturities.Also, bonds issued for 5-ycar short-term or 10-year short-term shall comprise only entire annual amortizations, starting by the last years of maturities, excluding the part which shall be for 20-year fixed-term.However, tenders shall be sent for one of tin-above methods of issue only, snd shall comprise only one of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint Hyacinthe.Capital and interest arc payable at all branches in the province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-ycar fixed-term for an amount equal to $13,000.However, if they are issued partly for 20-ycar fixed-term for an amount greater than $13,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on February 1st of each year, for the annual amount required t\" amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on tin-bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered ut u meeting of the Council to be held on Monday.January 19, 1970, at 9:00 o'clock p.m., in tin-Town Hull, 610 Chapleau St., Douville, county of Saint Hyacithc, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Douville (County of Saint-Hyacinthe), December 9.1969.Dominique Dupont, Secretary- Treasurer.Town Hall, 610 Chapleau St., Douville, County of Saint Hyacinthe, P.Q.Telephone: 774-4655, code 514.32530 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 83 I .I >l.11 iiiii-rl m-< ol :an Comté de Soulangcs Avis public est par les présentes donné epic des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations» seront reçues par le soussigné .1.E.Lucien Ranger, secrétaire-trésorier, Hôtel île ville, 67, rue Lippe, Station-du-Côtcau, comté de Soulangcs, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 20 janvier 1970, pour l'achat dc 8137,500 d'obligations de la Station-du-Côtcau, comté de Soulangcs, datées du 1er février 1970 et remboursables par séries du 1er février 1971 au 1er février 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annucllcment les 1er février et 1er août dc chaque année.Le taux d'intérêt peut cire le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlements numéros: 95 \u2014 878,000 \u2014 renouvellement d'umpnint; 96 \u2014 849,500 \u2014 renouvellement d'umprunt; 97 \u2014 S10.000 \u2014 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1970.Tableau d'amortissement \u2014 5137,600 \u2014 20 ans Aimée Capital 1er février 1971.S 4,500 1er février 1972.4,500 1er février 1973 .4,500 1er février 1974 .4,500 1er février 1975 .5,500 1er février 1976 .5,500 1er février 1977 .5,500 1er février 1978 .6,000 1er février 1979 .6,000 1er février 1980 .6,500 1er février 1981.7,000 1er février 1982 .7.000 1er février 1983 .7,000 1er février 1984 .8,000 1er février 1985.8,000 1er février 1986 .8,500 1er février 1987 .9,000 1er février 1988 .9,500 1er février 1989.10,000 1er février 1990.10,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le .-olde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 uns avec ic solde à courte échéance 10 ans pour une partie cl l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S10.50O, et si supérieur à ce dernier montant, ¦vite partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent la Stalion-dii-Côlcau County of Soulangcs Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.1.E.Lucien Ranger, Secretary-Treasurer, Town Hall, 07 Lippe St., Stalion-du-('ôleaii, county of Soulungcs, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Tuesday, January 20, 1970, for the purchase of an issue of $137,500 of bonds for Stalion-du-Coteau, county of Soulangcs, dated February 1, 1970, and redeemable serially from February 1, 1971 to February I, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8%, nor more than 9%, payable semi-annually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued ut each different rule must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-laws numbers: 95 \u2014 $78,000 \u2014 loan renewal ; 96 \u2014 $49,500 \u2014 loan renewal; 97 \u2014 $10.000 \u2014 loan renewal.For adjudication only, interest will be calculated as from February 1, 1970.Table of redemption \u2014 SIS7.S00 \u2014 20 years Year Capital February 1.1971.$ 4,500 February I, 1972.4,500 February 1, 1973.4,500 Febiuary 1, 1974.4.500 February I, 1975 .5.500 February 1.1976.5,500 February 1.1977 .5,500 February 1, 1978 .6.000 February 1, 1979.6,000 February 1, 1980.6,500 February 1, 1981.7,000 February 1, 1982 .7,000 February 1, 1983.7,000 February 1, 1984.8,000 February 1, 1985.8,000 February 1, 1986.8,500 Fcbniary 1, 1987.9,000 February 1, 1988.9,500 February 1, 1989.10,000 February 1, 1990.10.500 Moreover, only the following methods shall be taken into consideration: (1) Bonds maturing serially with 5-yeur, 10-year or 15-ycar short-term.(2) Bonds issuing in 10-year scries with the balance for 20-year fixed-term.(3) Bonds maturing in 10-year scries with the balance for 5-year short-term.(4) Bonds maturing in 10-year series with the balance partly for 10-year short-term and partly for 20-year fixed-term.(5) Bonds maturing in 10-year scries with Unbalance partly for 5-yeur short-term und partly for 20-year fixed-term.(6) Bonds maturing serially with the balance partly for 5-year short-term and partly for 20-ycar fixed-term.However, in the ease of paragraphs 4, 5 and 6, the bonds maturing at 20-year fixed-term shall be for an amount not less than $10,500, and, if higher than this latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice, starting by QAZliTTli OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1070, 102' année, n\"'! avis, cl en commençant par les dernières années d'échéances, Egalement, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises (pie pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des ternies sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Côtenii-Slntion.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesditcs obligations ne seront pas rachctables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries cl terme fixe 20 ans, pour un montant égal à 810,500.Toutefois si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 810,000.les obligations ainsi émises seront rachctables par anticipation, au pair, le 1er février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix olferl comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au momcnl de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 20 janvier 1970, à S heures du soir, Hôtel de ville, 07.rue Lippe, Station-du-Côtcau, comté de Soulangcs, l'.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Stution-dii-Côtcuii (Comté de Soulangcs), ce 17 décembre 1909.Ia; xerréla irc-lré.mrier, .1.E.Lucien Ranger.Hôtel de ville, 07.rue Lippe, Station-du-Côtcau (Soulangcs), l'.Q.Téléphone: 267-3551, code 514.32537-o the last years of the maturities.Also, bonds issued for 5-year short-term or 10-year short-term shall comprise only entire annual amortizations, starling by the last years of the matinilics.ahd excluding the part which shall be for 20-ycar fixed-term.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for Unbuilds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable al par ni Côtcau-Station.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will nut be redeemable by anticipai ion if they are issued serially or serially and for 20-ycar fixed-teim for an amount equal to 810.000.However, if they arc issued partly for 20-ycar fixed-term for ah amount greater than 810,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par.On February 1st of each year for the annual amount required to amortize I he issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender in us I be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on Unbuilds to the dale of their delivery is included or not in I he price of the tender.The tenders will be opened and considered ut a meeting of the Council to be held on Tuesday.January 20.1970, at 8:00 o'clock, in the Town Hall, 07 Lippe St.Station-du-Côtcau.county of Soulangcs, l'.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Station-du-Côtcau (County ôf Soulangcs).December 17.1009.1.E.Lucien Ranger, Scrrettrn-Treaxurer.Town Hall.07 Lippe St., Station-du-Côtcau (Soulangcs), l'.Q.Teh-phone: 207-3551, code 514.32537 Vente pour taxes Ville de Val d'Or Avis public, est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la sus-dite municipalité, que: Le conseil de ville de Val d'Or, par une résolution portant le numéro 630 en date du 15 décembre 1969, a ordonné nu soussigné, conformément aux articles 548 et suivants dc la Loi des cités et villes, de vendre les immeubles ci-dessous décrits, avec toutes les bâtisses dessus construites, dépendances et circonstances, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaire, intérêts, ainsi que pour payer les frais encourus pour et par la vente, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus ù l'enchère publique, MERCREDI, le VINGT-HUITIÈME jour de JANVIER 1970, à DIX heures de l'avant-midi, en la salle municipale dc l'Hôtel de ville, 855, 2c avenue, Val d'Or, P.Q.Sale for Taxes Town of Val d'Or Public notice, is hereby given by the undersigned, Town Clerk of the aforesaid municipality, that: The council of the town of Val d'Or, by resolution bearing number 630 dated December 15th, 1969 has ordered the undersigned, pursuant .to the provions of Articles 548 to 566 of the Cities and Towns Act, to sell the immovables herein-below described, with all the buildings thereon erected, circumstances and dependencies, to satisfy the payment of the municipal and schoo1 taxes, interest, and other charges incurred found by the sale, and that, consequently the said immovables will be sold by public auction in the Town Hall Council Chamber, 855, 2nd Avenue.Val d'Or, P.Q., on WEDNESDAY, THF TWENTY-EIGHTH day of JANUARY 1970, at TEN o'clock in the forenoon. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 85 Toutefois seront exclus de la vente, les immeubles sur lesquels les taxes municipales devenues exigibles le ou avant le 31 décembre 1967 auront été payées avant le moment de la vente.M.Jacques Martel, 805 Blvd des Lauren tides, ville de Laval, P.Q., lot No 41 partie nord rang Vm, canton Dubuisson, (41 partie nord).Taxe municipale: 884.64; taxe scolaire: $141.37; intérêt et frais: $44.85.Total: $270.86.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54 A-4 partie non-subdiviséc rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4 P.N.S.).Taxe municipale: $324.74; taxe scolaire: $225.25; intérêt et frais: $66.89.Total: $616.88.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa, 7, Ont., lot No 54 subdivision No A-4-21, rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4-21), Taxe municipale: $91.81 ; taxe scolaire : $16.08; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72.M.Prudent Laradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54 subdivision No A-4-22, rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4-22).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: S16.0S; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54 subdivision No A-4-23, rang Vin, canton Dubuisson, (54 A-4-23).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: $10.08; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72._ M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54 subdivision No A-4-24, rang Mil, canton Dubuisson, (54 A-4-24).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: $16.08; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54, subdivision No A-4-25, rang Vni, canton Dubuisson, (54 A-4-25).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: S16.0S; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54, subdivision No A-4-26, rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4-26).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: $16.08; intérêt et frais: $36.83.Total: $144.72.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No 54, subdivision No A-4-27, rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4-27).Taxe municipale: $91.81; taxe scolaire: $16.08; intérêt et frais: 836.83.Total: $144.72.M.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont.; lot No 54, subdivision No A-4-28, rang VIII, canton Dubuisson, (54 A-4-28).Taxe municipale: $S9.81; taxe scolaire: $16.08; intérêt et frais: $36.44.Total: $142.33.M.Alfred Roy, 8 rue Lauzon, Val d'Or, P.Q.; lot No 54, subdivision No A-4-2, rang VIII, canton Dubuisson, avec bâtisses et dépendances (54 A-4-2).Taxe municipale: $453.49; taxe scolaire: $46.14; intérêt et frais: $55.94.Total: $555.57.M.Jean Jacques Englchart, Rang V, Val Scn-ncville, P.Q.; Lot No 54, subdivision No A-5-14, rang VIII, canton Dubuisson, (54-A 5-14) .Taxe municipale: $87.36; taxe scolaire: $19.25; intérêt et frais: $40.24.Total: $146.85.M.Roméo Lauzon, R.R.§ 2, Val d'Or, P.Q., lot No 54, subdivision No A-5-15, rang VLÏI, canton Dubuisson, (54 A-5-15).Taxe municipal: S84.00; taxe scolaire: $0.40; intérêt et frais: $34.77.Total: $119.17.M.Antonin Bigaouette, CP.343, Belle Rivière, Ont., lot No 55, subdivision No A-5-22, rang VIII, canton Dubuisson, (55 A-5-22).Taxe municipale: $94.07; taxe scolaire: $16.04; intérêt et frais: $36.36.Total: $147.07.However there shall be excluded from the sale, the immoveables on which municipal taxes falling due on or before December 31st, 1967, shall have been paid prior to the sale.Mr.Jacques Martel, 805 Laurcntide Blvd, Ville de Laval, P.Q., lot No.41 north part, range VIII, township of Dubuisson, (41 north P.).Municipal taxes: $S4.64; school taxes: $141.37; interest and costs: $44.85.Total: $270.86.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54 A-4, unsubdivided part, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4 U.P.).Municipal taxes: $324.74; school taxes: $225.25; Interest and costs: $66.89.Total: $616.88.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54, subd.No.1-4-21, range VIII.township of Dubuisson, (54 A-4-21).Municipal taxes: $91.81; school taxes: $16.08; interest and costs: $36.S3.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont, lot No.54, subdivision No.A-4-22, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4-22).Municipal taxes: $91.81; school taxes: S16.08; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54, subdivsion No.A-4-23, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4-23).Municipal taxes: $91.81; school taxes: $16.08; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54, subdivision No.A-4-24, range Vm, township of Dubuisson, (54 A-4-24).Municipal taxes: $91.81; school taxes: $16.08; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54, subdivision No.A-4-25, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4-25).Municipal taxes: $91.81; school taxes: 816.08; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont., lot No.54, subdivision No.A-4-26, range Vm, township of Dubuisson, (54 A-4-26).Municipal taxes: $91.81; school taxes: $16.08; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont, lot No.54, subdivision No.A-4-27, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4-27).Municipal taxes: $91.81; school taxes: S16.0S; interest and costs: $36.83.Total: $144.72.Mr.Prudent Paradis, 1004 River Road, Ottawa 7, Ont, lot No.54, subdivision No.A-4-28, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-4-28).Municipal taxes: $89.81; school taxes: S16.08; interests and costs: S36.44.Total: $142.33.Mr.Alfred Roy, 8 Lauzon St., Val d'Or, P.Q., lot No.54, subdivision No.A-4-2, range VIII, township of Dubuisson with the buildings thereon erected and dependencies.(54 A-4-2).Municipal taxes: $453.49; school taxes: $46.14; interest and costs: $55.94.Total: S555.57.Mi.Jean J.Englchart, range V, Val Senncville, P.Q., lot No.54, subdivision no A-5-14, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-5-14).Municipal taxes: $87.36; school taxes: $19.25; interest and costs: $40.24.Total: $146.85.Mr.Roméo Lauzon, R.R.#2, Val d'Or, P.Q., lot No.54, subdivision No.A-5-15, range VIII, township of Dubuisson, (54 A-5-15), Municipal taxes: $84.00; school taxes: $0.40; interest and costs: $34.77.Total: $119.17.Mr.Antonin Bigaouette, P.O.Box 343, Belle Rivière, Ont, lot No.55, subdivision No.A-5-22.range VIII, township of Dubuisson, (55 A-5-22), Municipal taxes: $94.67; school taxes: $16.04; interest and costs: $36.36.Total: $147.07. 86 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 M.Gérard Binette, 410, 13e Rue, Val d'Or, P.Q., lot No 83, subdivision No 13, rang VII, canton Dubuisson, (83-13 R.7).Taxe municipale: 8106.10; intérêt et frais: $36.91.Total: $143.01.M.Cylien Petit, 525, 27e Ave, app.12, Pointe aux Trembles, P.Q., lot No 99, subdivision No 5, rang VII, canton Dubuisson, (99-5 R.7).Taxe municipale: $123.54; taxe scolaire: $41.24; intérêt et frais: $43.77.Total: $208.55.M.Leopold Trudel, 612, rue Laval, Malartic, P.Q., lot No 102, subdivision No 4, rang VII, canton Dubuisson, (102-4 R.7).Taxe municipal: 891.50; intérêt et frais: $32.24.Total: $123.74.M.Sylva Rioux, 343, 6c Rue, Val d'Or, P.Q.; lot No 107, subdivision No 1-9, rang VII, canton Dubuisson, (107-1-9 R.7).Taxe municipale: $100.03; intérêt et frais: $35.73.Total: $135.76.Le prix d'adjudication dc chacun dc ces immeubles sera payable immédiatement.Tous les immeubles vendus sont sujets au droit de retrait d'un an.Donné à Val D'Or, P.Q., ce seizième jour dc décembre mil neuf cent soixante-neuf.Certifié copie conforme.Le greffier, 32468-52-2-0 (Signé) Albert Piiilbert.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ARTHABASKA Canada \u2014 Province de Québec District d'Arthabaska Cour Supérieure, ( CAISSE POPULAIRE DE No 21716.\\ VICTORIA VILLE, dc- * manderesse, r.i BENOIT SI-NOTTE, défendeur.« Un terrain ou emplacement situé dans la municipalité dc la paroisse dc St-Valèrc dc Buls-trode, dc figure irrégulière contenant 200 pieds de front dans sa ligne est, et 250 pieds dans sa ligne sud.la ligne nord et nord-ouest étant constituée par le cours dc la rivière Nicolet; ce terrain est connu et désigné au cadastre officiel du canton de Bulstrodc comme faisant partie du lof six cent trente-six (P.036) borné au nord et au nord-ouest à la rivière Nicolet aussi appelée à cet endroit Rivière du Loup, au sud à la ligne divisant les onzième et douzième rang (lu canton dc Bulstrodc, et à l'est à un chemin privé à l'usage des propriétaires et occupants des divers emplacements dans le voisinage; avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et tout le mobilier qui s'y trouve présentement.Tel qUe le tout se trouve avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes pouvant concerner ledit immeuble et plus particulièrement un droit dc passage avec tous autres y ayant-droit sur un chemin privé traversant le No 773 du même cadastre dans le sens de la longueur, dans la ligne divisant la partie Mr.Gérard Binette, 410, 13th St., Val-Or, P.Q., lot No.83, subdivision No.13, range VII, township of Dubuisson, (83-13 R.7).Municipal taxes: 8106.10; interest and costs: $36.91.Total: $143.01.Mr.Cylien Petit, 525, 27th Ave, Apt.12, Pointe aux Trembles, P.Q., lot No.99, subdivision No.5, range VII, township of Dubuisson, (99-5 R.7).Municipal taxes: $123.54; school taxes: $41.24; interest and costs: $43.77.Total: $208.Mr.Leopold Trudel, 612 Laval St., Malartic, P.Q., lot No.102, subdivision No.4, range VII, township of Dubuisson, (102-4 R.7).Municipal taxes: $91.50; interest and costs $32.24.Total: $123.74.Mr.Sylva Rioux, 343, 6th St., Val d'Or, P.Q., lot No.107, subdivision No.1-9, range VII, township of Dubuisson, (107-1-9, R.7).Municipal taxes: $100.03; interest and costs: $35.73.Total: $135.76.The purchase price of each of the said immoveables, shall be payable immediately.All the immovables sold arc subject to the one year right of redemption.Given at Val d'Or, P.Q., this sixteenth day of December, 1969.Certified true copy.(Signed) Albert Piiilbert, 32468-52-2-0 Town Clerk.Sheriffs' Sales PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA Canada \u2014 Province of Québec District of Arthabaska Superior Court, ( /BAISSE POPULAIRE DE No.21716.VICTORIAVILLE.I plaintiff, vs BENOIT SI-NOTTE, defendant.\"A piece of land or emplacement situated in the municipality of the parish of St-Valère de Bulstrodc, of an irregular figure containing 200 feet in front on its east line and 250 feet on its south line, the north line and north-west line being constituted by the course of Nicolet River; this land is known and designated on the official cadastre of the township of Bulstrodc as being part of lot six hundred and thirty-six (P.636) bounded on the north nnd north-west by Nicolet River also called at this place Rivière du Loup, on the south by the line dividing the eleventh and twelfth range of the township of Bulstrodc, and on the east by a private road used by the proprietors and occupants of various emplacements in the vicinity; with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, and the entire movables presently found thereon.As the whole is found with all servitudes, active and passive, apparent or occult which may concern the said immovable and particularly a right of way with all others having a right on the private road crossing No.773 of the same cadastre on the length, on the line dividing the part of the said lot belonging to Ena Fournier QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January S, 1970, Vol.102, No.1 87 dudit numéro uppurtenunt à Enu Fournier et celle appartenant à Laurent Poirier ou représentants de ces derniers, pour communiquer au chemin public du douzième rang ou route numéro .34, tel que ce droit dc passage avait été réservé par Alexandre Hébert en un acte de vente par lui consenti à Évuristc Bergeron et Ena Poirier passé devant Me Joseph Désilcts, notaire le 21 octobre 1947 enregistré sous le numéro 980f>7, 11.126.Ixulit terrain est dc plus assujetti à une servitude active permettant à l'acquéreur et à ses représentants à l'avenir à la propriété et à l'occupation dudit terrain dc circuler librement avec tous autres y ayunt droit sur les chemins privés sillonnant la partie dudit numéro 636 de Bulstrodc pour ullcr jusqu'à la rivière Nicolet qui coule dans le voisinage et permettant également au même acquéreur ou représentants à l'avenir de passer et dc séjourner à leur discrétion sur cette partie basse et sablonneuse du même numéro qui s'étend le long dc Indite rivière Nicolet, vers le nord, et le droit de s'y beigner et de prendre ses ébats dans ladite rivière, ladite partie sablonneuse du terrain du vendeur originaire Alexandre Hél)crt devenant une plage à l'usage des divers ucquéreurs dc ces terrains et à l'usage de leurs visiteurs, cette servitude est perpétuelle.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement, 33, rue Laurier à Arthabaska, le SIXIÈME jour île FÉVRIER 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.32542-0 LÉO Fauciiku.I B E II V I L L E Fieri Facias île Bonis el de Terris Cour Provinciale \u2014 District d'Ibcrvillc Saint-Jean, à savoir: ( JACQUES RANCOURT, No 7946.{ J L.ROY.A.RENÉ & l J.P.GRENIER, avocats membres en règle du Barreau de la province de Québec et comme tels ont payé leur cotisation pour l'année en cours et faisant affaires à St-Jciin, district d'Ibcrvillc, demandeurs rs ALEXANDRE McCRAW, actuellement résidant à 60, rue lie l'Église, Ile Stc-Thérèse, défendeur.« Une maison située au 60, rue de l'Église sur l'Ile Stc-Thérèse, paroisse St-Luc, district d'Ibcrvillc, connue et désignée comme étant le lot 104 du lot originaire 236, soixante (60) pieds en front, soixante-quinze (75) pieds en urrière, cent (100) pieds en profondeur et 7387 pieds en superficie, en plan et livre dc renvoi officiel de la paroisse de St-Luc, division d'enregistrement dc Saint -Jean.» Pour être vendu nu bureau d'enregistrement du comté dc Saint-Jean, en la ville de Suiut-lean, le DIXIÈME jour de FÉVRIER 1970, à DIX heures de l'avant-midi./.c shérif.Bureau du Shérif, CLAUDE AUDBT., Saint-Jean, P.Q., ce 23 décembre 1969.32543-o MONTRÉAL Fieri Facias dc Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Montréal, |-\"THE CANADA TRUST COM-778383.\\ J- PANY, un corps politique et l constitué dûment incorporé et ayant >oii siège social en la cité dc London, en la and that belonging to Laurent Poirier or representatives of the latter, to communicate from the public road of the twelfth range to route number 34, such as this right of way had been reserved by Alexandre Héliert in a deed of sale agreed upon by him to Évuriste Bergeron and Ena Poirier passed l«forc Me Joseph Désilcts, notary, on October 21, 1947, registered under number 98067, B.126.The said land is also subject to un active servitude allowing the purchaser and his representatives in the future to the property and occupation of the said land to circulate freely with all others having a right thereto on the private roads enclosing the part of said number 636 of Bulstrodc to the Nicolet River which flows in the vicinity and also allows to the same purchaser or representatives in the future, the right to pass and sojourn to tl cir discretion on this low and sandy part of the same number which flows along the said Nicolet River, to the north, and the right to swim there and to frolic in the said river, the said sandy part of the land of the original vendor Alexandre Hébert becoming a lieach for the use of various purchasers of these lands and for the use of their visitors, this servitude is perpetual.\" To be sold at the registry office, 33 Laurier Street, at Arthabaska.the SIXTH day of FEBRUARY, 1970, at TEN o'clock in the morning.Leo Faucher, 32542 Sheriff.IBERVILLE Fieri Facias de Bonis et de Terris Provincial Court \u2014 District of Iberville Saint John's, to wit: ( JACQUES RANCOURT, No.7946.j J L.ROY.A.RENÉ & I J.P.(.RENIER, advocates, members in good standing of the Bur of the Province of Québec, who have paid their dues for the current year, and who are currying on business nl St.John's, district of Iberville, plaintiffs, m ALEXANDRE McCRAW, now residing at 60 de l'Église St., Ile Stc-Thérèse, defendant.\"A house situated at 60 de l'Église St., on Ile Ste-Thérèse, parish of St-Luc, district of Iberville, known and designated as being lot 104 of original lot 236, mcusuring sixty (60) feet in front, seventy-five (75) feet in the rear, one hundred (100) feet in depth, and having an area of 7387 feet, on the plun und in the ofliciul liook of reference of the parc-h of St-Luc, registration division of St.John's.\" To be sold in the registry olfice for the county of Saint John's, in the town of Saint John's, on the TENTH day of FEBRUARY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Claude Audet, Sheriff's Office, Sheriff.Saint John's, P.Q., December 23, 1969.32543 MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montréal, C '\"THE CANADA TRUST CO.M-778383.» L PANY, n body politic und ' corporulc, duly incorporated und having its head office in the city of London, in 88 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1070, 102' année, n\" 1 province d'Ontario cl sa principale place d'affaires pour la province dc Quebec, en la ville de Montreal, district de Montréal, GUI ouest, boulevard Dorchester, demanderesse, vs RAYMOND BOUCHER, des ville cl district de Montreal, sa dernière adresse connue élunl 3181, place Hélène Boulay.défendeur, et C.A.MICHAUD, en sa qualité de syndic dc la succession de Raymond Boucher, en faillite, des ville et district de Montréal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la place Hélène Boulay, en la ville dc Montréal, connu el désigné comme étant les lots numéros treize et quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro six (6-13 et 1-1) aux plan el livre de renvoi Officiels de la paroisse dc Saint-Laurent, mesurant cinquante-trois pieds et quatre-vingt-quatorze centièmes (53.94 ) de largeur en front, cinquante-trois pieds el quarante-six centièmes (53.46') de largeur à l'arrière sur une profondeur dc quatre-vingt pieds (S!)'), le tout, mesure anglaise cl plus ou moins.Avec les bâtisses dessus érigées cl portant le numéro civique 3181 dc ladite place Hélène Boidé.en la ville de Montréal.Ainsi que le tout subsiste présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, appareilles ou occultes y attachées.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au vieux Palais de Justice, en la Ville dc Montréal, district de Montréal, le SIXIÈME jour de FÉVRIER 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif.Paul St-M aiitix.Montréal, 17 décembre 196!).43251 Ihe Province of Ontario, and its chief plaça of business for the Province of Québec, in the city of Montreal, in the district of Montreal.631 Dorchester Boulevard West, plaintiff, r.v RAYMOND BOUCHER of the city and district of Montreal, his last, known address being 3181 Place Hélène Boulay, defendant and ('.A.MI-CHAUD, in his quality as Trustee of the Estate of the I la uk lu pi Raymond Boucher, of the city and district of Montreal, mis en cause.\"An emplacement fronting on Hélène Boulé Place, in the city of Montreal, known and designated as lots numbers thirteen and fourteen of the ollicial subdivision of original lot number six (6-13 and 14) upon the ollicial plan and in the book of référence of the parish of St.Laurent, measuring fifty-three feet and ninety four hundredths of a foot (53.94') in width in front, fifty-three feet and forty-six hundredths of a foot (53.46') in width in rear by a depth of eighty feet (SO') the whole English measure and more or less.With the buildings Ibereon erected bearing civic number 3181 on said Hélène Boulé Place, in the city of Montreal.As the whole now subsists with all active ami passive apparent or occult servitudes attached thereto.\" 'To be sold al Ihe prothonolary's office, room #129, at the Old Court House, in the city of Montreal, district of Montreal, on the SIXTH day of FEBRUARY.1970.al TWO o'clock in the afternoon.Paul St-Mautix, Sheriff's Ollice.Assistant Sheriff.Montreal.December 17, 1969.32544-.Fieri Facias de Terris Cour Provinciale \u2014 District dc Montréal Montréal, ( rPHE CONSOLIDATED FUND 216612.\\ J- LTD., un corps politique et constitué, dûment incorporé comme tel, et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en la cité de Lachine, district dc Montréal, (1875.52e avenue), demanderesse, rs FERDINAND RIPORTELLA.ville Mont-Royal, district de Montréal, (85, chemin Henley), défendeur.« Us lots 623-2461-2 et 623-2462-1 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sainl-Liiurent, avec ensemble lu bâtisse dessus érigée et portant le numéro civique 85, chemin Henley, ville Mont-Royal.» Pour être vendus au bureau du protonotaire, chambré #129, au vieux Palais de Justice, en In ville de Montréal, district de Montréal, le CINQUIÈME jour de FÉVRIER 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Paul St-Mautix.17 décembre 1969.32545 Fieri Farias de Terris Provincial Court \u2014 District of Montreal Montreal, (\u2022 T'HE CONSOLIDATED FUND 216612.j J- LTD., a body politic and corporate duly incorporated as such, and having its head ollice and principal place of business in the city of Lachine, district of Montreal (1875, 52nd Avenue), plaintiff, vs FERDINAND RIPORTELLA, town of Mount Royal, district of Montreal (85 Henley Road), defendant.\"Lois nos 623-2461-2 and 623-2462-1 upon the ollicial plan and book of reference of the parish of Si-Laurent, together with the building thereon erected and hearing civic number 85 Henley Road, town of Mount Royal.\" To be sold at the Prothonotury's Ollice, room #129, at the Old Court House, in Ihe city or Montreal, district of Montreal, on the FIFTH day of FEBRUARY 1970 at TWO o'clock in the afternoon.Paul St-Mautix.Sheriff's Ollice, Assistant Sheriff.December 17, 1969.32545-0 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal Montréal, | TTAMPSHIRE REALTIES No 772 774.) A l LTD., corps politique et ' corporation dûment incorporée selon la loi, ayant son bureau chef, en les cité et district de Montréal, demanderesse, rs JEAN CLAUDE DESBIENS, contracleur dc la Cité de Poinle-aux-Trembles, résidant et domicilié au 1075, de Poitou, ù Pointe-aux-Trembles, défendeur, et RENÉ LANGEVIN, régistratcur, en sa qualité de régistrateur pour la division d'enregistrement de Montréal, mis-en-cause, et Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, j' TJAMPSHIRE REALTIES No.772 774.j J-L LTD., body politic and ' corporate, duly incorporated under the Act, having its head office in the city and district of Montreal, plaintiff, M JEAN CLAUDE DESBIENS, contractor of the City of Pointeaux-Trembles, residing and domiciled at 1075 de Poitou, at Pointe-aux-Trembles, defendant, and RENÉ LANGEVIN, registrar, in his capacity as registrar for the registration division of Montreal, mis-en-causc, and MRS.BERTHE QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1070, Vol.102, No.I 89 DAME BERTHE LANDRY, veuve non remariée de feu Orner Leelcre, de son vivant de la ville et district de Montréal, mis-cn-eause.« Un emplacement ayant front sur la cinquante et unième avenue, en la ville de Pointe-àux-Trcmblcs, composé des lots de terre connus et désignée sous les numéros cent quarante-sept et Miil quurantc-lmit, de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent dix (210-147 et 148) aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse de l'ointc-aux-Trcmbles, mesurant chacun vingt-cinq pieds dc largeur par quatre-vingt-douze pieds de profondeur, mesure anglaise.Avec une bâtisse dessus érigée portant les numéros 1075, 1077 et 1079, 51e avenue, Pointeaux-Trembles.Tel que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives el passives, apparentes ou occultes y attachées et sans aucune exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau du Protonotaire, chambre #129, au vieux Palais dc Justice, en la ville de Montréal, le SIXIÈME jour de JANVIER 1970, à ONZE heures dc l'uyant-midi.Ia: shtrif adjoint.Bureau du Shérif, Paul St-Maiitix.Montréal, ce 18 décembre 1969.32546-0 Fieri Facias dc Hon is cl dc Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal (VEY INVESTMENTS No.766-195.-\\ JN.LTD., corps politique et ' incorporé, dûment incorporé suivant la loi, et ayant son siège social et sa principale place d'affaires pour la province dc Québec, en les ville et district de Montréal, demanderesse, rs JOSEPH MIGNOLET, de la Ville dc St-Bruno dans le district dc Montréal, et y demeurant à 1958, rue Des Cèdres, défendeur.« Un emplacement situé en lu Ville dc St-Bruno, ayant front sur la rue Des Cèdres, connu cl désigné comme étant les lots numéros huit et neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois cent quarante-neuf (Nos.349-8 et 9) aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse de St-Rruno, mesurant le lot No.1549-9 soixante pieds (60') de largeur sur des profondeurs dc cent vingt-sept pieds et huit pouces tl27'8\") dans sa ligne sud-est et cent vingt-huit pieds et trois pouces (128'3\") duns su ligne nord-ouest, et le lot No.349-8, soixante pieds de largeur sur cent vingt-huit pieds et trois pouces i!28'3\") dc profondeur dans sa ligne sud-est et cent vingt-neuf pieds (129') dans sa ligne nord-ouest, mesure anglaise et plus ou moins.Avec une maison dessus érigés.» Fait et exécuté ainsi sur l'immeuble ci-dessus mentionné, ce lie jour dc décembre 1969, à deux heures de l'après-midi.Pour être vendu uu bureau du protonotaire, chambre #129, au vieux Palais de Justice dans la ville dc Montréal, district dc Montréal, le TROISIÈME jour du mois de FÉVRIER, 1970, à DEUX heures dc l'après-midi.Ia: ehfrif adjoint.Bureau du shérif, Paul St-Martix.Montréal, le 18 décembre 1969.32547-0 Fieri Facias dc Bonis de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal Montréal, ( TfLIANE MONAST, ménagère, .les 776-856.\\ ville et district dc Montréal, ' veuve non-rcmariée dc feu Oscar I.lissier, de son vivant du même endroit, deiiian- LANDRY, unremarried willow of the latc Omcr Lcclerc, when living of the city and district of Montreal, mis-en-cause.\"An emplacement fronting on Fifty-first Avenue, in the City of Pointe-aux-Trcmbles, composed of the lots of land known and designated under numbers one hundred and forty-seven and one hundred and forty-eight of original the subdivision of lot number two hundred und ten (210-147 and 148) on the official plan and book of reference of the parish of Pointe-aux-Trcmbles.each measuring twenty-five feet in width by ninety-two feet in depth, English measure.With a building erected thereon bearing numbers 1075.1077 and 1079, 51st Avenue, Pointe-aux-Trcmbles.As the whole is presently found with the servitudes, active and passive, apparent or occult attached thereto and without exception nor reservation.\" To lie sold at the ollice of the prothonotary.Room #129, at the old Court House, in the City of Montreal, on the SIXTH day of JANUARY, 1970, at ELEVEN* o'clock in the morning.Paul St-Maktix, Sheriff's Oflicc, Associate Sheriff.Montreul, December IS, 1969.32546 Fieri Facias dc Bonis et de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal j V-EY INVESTMENTS No.766-195.j J*- LTD., a body politic ' and corporate, duly incorporated according to law, having its head office and principal place of business for the province of Québec, in the city and district of Montreal, plaintiff, vs JOSEPH MIGNOLET.of the town of St-Rruno in the district of Montreal therein residing at 1958 Des Cidres street, defendant.\"An emplacement situated in the Town of St-Bi iuio.fronting on Des Cèdres St., known und designated as being lots numbers eight and nine of the official subdivision of original lot number three hundred and forty-nine (Nos.349-8 and 9) on the official plan and in the book of reference of the Parish of St-Bruno, measuring, lot No.349-9, sixty feet (60') in width by depths of one hundred and twenty-seven feet and eight inches (127'8\") on its southeast line and one hundred and twenty-eight feet and three inches (128'3\") on its northwest line; lot No.349-8 measures sixty feet in width by one hundred and twenty-eight feet and three inches (128'3\") in depth on its southeast line and one hundred and twenty-nine feet (129') on its northwest line, English measure and more or less.With a house erected thereon.\" Thus done and executed on the immovable property, abovemcntioned, this 11th day of December, 1909, at 2:00 o'clock in the afternoon.To be sold at the prothonotary's office room #129, at the old Court House, in the city of Montreal, district of Montreal, on the THIRD day of the month of FEBRUARY 1970, at TWO o'clock in the afternoon.Paul St-Maktin, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Montreal, December 18, 1969.32547 Fieri Facias de Bonis de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal Montreal, [ T7-LIANE MONAST, housewife, of 776-856.j J-» the city and district of Mont-¦ real, unremarried widow of the lute Oscar Lussicr, in hislifetime of the same place, 00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, n\" 1 deresse, r* FERNAND ASSELIX, des ville et district dc Montréal, défendeur.« Ce cerluin cmplnccmcnt ayant front sur lu.rue Louis Xormnndin, en lu municipalité dc liouclicrville, en lu province de Québec, étant plus particulièrement désigné comme étant lu subdivision numéro quurunte-six du lot originaire numéro vingt-deux (22-46) aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse dc Stc-Famillc de Hoiichcrville.Avec la bâtisse dessus érigée et portant le numéro civique 785 de ladite rue Louis Xormnndin.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au vieux Palais dc Justice, en la ville de Montréal, district dc Montréal, le CINQUIÈME jour de FÉVRIER 1970, à ONZE heures du matin.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Paie St-Mahtin.Montréal, 17 décembre 1969.32548 plaintiff, y s FERNAND ASSELIN, of the city and district of Montreal, defendant.\"Thut certain emplacement fronting on Louis Normundin Street, in the municipality of Bouchervillc, in the Province of Québec, being more purticulurly designated as subdivision number forty-six of the original lot number twenty-two (22-46) on the official plan and book of reference of the parish of Ste-Famillc de Bouchervillc.With the building thereon erected bearing civic number 785 on said I.nuis Normandin Street.\" To be sold ut the prothonotary's office, room #129, at the Old Court House, in the city of Montreal, district of Montreal, on the FIFTH day of FEBRUARY 1970, at ELEVEN o'clock in the morning.Pali.St-Mautin, Sheriff's Ollice, Assistant Sheriff.Montreal, December 17, 1969.32548-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Quélicc, à savoir : ( A LB E R T BÉDARD, Cour Provinciale, J épicier-boucher, faisant No 35-928.\\ affaires à 426 rue Victoria.\\ Québec, ta MMEYVE ARTHUR GIROUX, domiciliée à 577 Kirouac, Québec.« Le lot No 1746 du cadastre officiel dc St-Sauveur, borné vers le nord par lu rue St-Fluvien, vers le sud, par le No 1755, vers l'est par le Xo 1745 et vers l'ouest par le No 1747 mesurant quarante-deux pieds dix pouces sur la rue St-Fluvien quarante-deux pieds dix pouces sur lu ligne qui le divise du'No 1755, soixunte-trois pieds six pouces sur lu ligne qui le divise du No 1745 et soixunte-trois pieds six pouces sur In ligne qui le divise du No 1747, contenunt en sui>crficie deux mille sept cent dix-neuf pieds mesure nngluisc (2719) égul à deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze pieds français (2394), avec bâtisses dessus construites, circonstance et dépendances.» Pour être vendu à la salle d'Assemblée, chambre A 24, Palais de Justice, Québec, le TROISIÈME jour de FÉVRIER 1970, u DIX heures de l'a vaut-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 29 décembre 1969.32549-o QUÉBEC Fieri Facias dc Terris Québec, to wit:/ ALBERT BÉDARD.Provincial Court,) ** groccr-butchcr, carrying No.35-928.) on business at 426 Victoria { Street.Québec, rs MRS.ARTHUR GIROUX, widow, residing at 577 Kirouac, Quél>cc.\"Lot No.1746 of the official cadastre of St-Sauvcur, hounded on the north by St-Flavicn Street, on the south, by No.1755, on the cast by No.1745 and on the west by No.1747 measuring forty-two feel ten inches on St-Flavien Street forty-two feet ten inches on the line dividing it from No.1755, sixty-three feet six inches on the line which divides it from No.1745 and sixty-three feet six inches on the line which divides it from No.1747, containing in area two thousand seven hundred and nineteen feet, English measure (2719) equal to two thousnnd three hundred and ninety-four French feet (2394), with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To be sold nt the Assembly Hall, Room A 24.at the Court House, in Québec, on the THIRD day of FEBRUARY, 1970.at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Haixs, Sheriff's Office, Associate Sheriff.Québec, December 29, 1969.32549 INDEX No 1 ARRÊTÉS en Conseil ORDERS in Council 3985 \u2014 Population des municipalités.64 3985 \u2014 Population of municipalities.64 4058 \u2014 Bois ouvré, Québec.61 4058 \u2014 Wrought wood, Québec.61 4059 \u2014 Employés de garages, Trois-Rivières et Shawinigan.02 4059 \u2014 Garage Employees.Trois-Rivières und Shawinigan.62 4060 \u2014 Alimentation, détail, Chicoutimi.61 4060 \u2014 Food, Retail, Chicoutimi.61 4061 \u2014 Alimentation, Jonquièrc.62 4061 \u2014 Food, Jonquièrc.\u2022.- 62 4062 \u2014 Lignes de transport d'énergie électrique et lignes dc distribution d'énergie électrique, province._.62 4062 \u2014 Electric Power Transmission Lines and Electric Power Distribution Lines, Province.62 4063 \u2014 Automobile, Mauricic-St.Maurice Valley.63 4064 \u2014 Coiffeurs, Roberval.63 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January .1, 1970, Vol.102, No.I 91 ARRÊTÉS en Conseil (suite) 4004 \u2014 Hairdressers, Robcrvul.4005 \u2014 Coiffeurs |M>ur dames, Montréal.4005 \u2014 Hairdressers (Ladies') Montreal.4000 \u2014 Hois ouvré, Québec.4060 \u2014 Wrought wood, Québec.4067 \u2014 Alimentation, Chicoutimi.4007 \u2014 Food, Chicoutimi.ORDERS in Council (continued) 63 63 63 64 64 64 64 CHANGEMENT DE NOM Loi du CHANGE OF NAME - Ici André dit Dream, Jean Pierre, Camille Désiré (Dem.-Appl.).Brown, Lynda Carroll (Acc.-Grant.).Fournier, Joseph, Lucien Jean Paul (Acc.-Grant.).Moisan, Joseph Laurent Arnold (Acc.-Grant.).Parent, Joseph Nicol (Dcm.-Appl.).Rafla, Albert (Acc.-Grant.).BILLS Sanctionnés.Sanctioned.RILLS 65 65 COMPAGNIES Vvis relatifs à lu loi des Chartes \u2014 demandes d'ubuiidon dc COMPANIES Notices relative to the Act of Charters - -Applications for Surrender of .66 Construction Port-Joli ltée.F.A.S.Import Ltd.66 Ferroni (Québec) ltée.66 Hochelugn Metal Fabricators Inc.66 Jatl Construction inc.\u2022 \u2022 \u2022 \u2022.66 Manchester Importers Limited.66 Mnuriciu Développement Inc.67 Waterloo Industrial Development Co- pnny Limited.67 Dissoutes Dissolved < 'hoinedey Tennis Club Inc.60 Club dc Tennis de Chomcdcy inc.60 Dal-Laur Land Holding Corp.60 Fifteen Hundred and Fifty-Nine McGregor Street Investment Corp.(if) Hôpital d'Youvillc de Sherbrooke (I/).60 North Development Construction Ltd.60 Oak Leaf Transport Co.Ltd.til R.B.G.Construction Inc.61 Divers Miscellaneous Boucherie Idéale (Raie-Comeau) inc.(Dir.).67 Business Dynamics Incorporated (Dir.) 67 ( 'anots Cadorctte Canoes Inc.(Dir.).07 Centre Constance Lcthhridgc (Dir.).67 Centre Constance Lcthbridge (Rcgl.).68 ('ley & Tinker, Ltd.(Dir.).68 Custom Kitchen and Sheet Metal Works Ltd.(Dir.).68 Gestad inc.(Dir.)._.68 Grace Dart Hospital Foundation (Rcgl.- Btj-law).68 Greenfield Purk Lumber & Builders' Supplies Ltd.(Dir.).68 Grondin (J.Reginald) Inc.(Dir.).68 Immeubles Pollack (Trois-Rivières) limitée (Les) (Dir.).69 Lcthhridgc (Constance) Centre (Dir.).67 l.clhbridge (Constance) Centre (Bij- luws).68 Mental Hygiene Institute Inc.(The) (Dir.).69 Merchants'Overseas Corporation (Dir.) 69 Placements d'Auteuil inc.(Les) (Dir.).Pollack's Ltd.(Dir.).Pollack (Maurice) Realty Company Limited (Dir.).Pollack Properties (Trois-Rivières) Limited (Dir.).Suitmastcr Inc.(Dir.).Voyages Granby, inc.(Dir.).71 72 71 72 71 72 69 69 69 69 69 Lettres patentes Aéro-6 inc.IAiliers Patent .2 Air-Gcst International Corp.2 Air-Structure Company Ltd.3 Ameublements Chnmplain inc.(Les) .3 Artimondc inc.3 As Pec Wee d'Alma inc.(Les).4 Association Sportive Internationale dc l'Amérique du Nord.4 Atelier de Créateurs C.B.S.P.inc.(L') 13 Au Réveillon des Gagnon inc.4 Autodrome Trois-Rivières ltée.5 Beaucourt Furs of Québec Ltd- 5 Beaucourt pelleteries du Québec ltée 5 Bclcraft.6 Bcrmatcx Inc.6 Bessette (E.) inc.6 Betty & Carrier inc.7 Boules de miel Carnaval inc.7 Boutique Galion inc.7 Branded Enterprises Limited.8 Brûleurs d'Asbestos inc.(Les).8 Caractype inc.8 Carnival Honeyballs Inc.7 Cel-Tcr inc.Centre dc Ski et dc Villégiature dc Sut-ton inc.52 Champagne (Jean-Marie) inc.Citadel Cleaners Inc.37 Clinique d'Auto Généreux inc.9 Club Auto-Neige de l'Avenir inc.10 Club Auto-Neige St-Muthias.10 Club Auto-Sport Lévis inc.10 Club de pêche Musquaro inc.Club des « 5000 » (Patro Roc-Amadour) Il Club des Loisirs-Danse Riviera inc.11 Club Sportif des Lacs du Nord inc.12 Conseillers en Personnel Nord-Américains liée.,.39 Commerce Éditions.15 Country Music Production (Ottawa) Limited.12 Couture (A.G.P.) & frères inc.12 Creative Department C.B.S.P.Inc.13 Croteau (II.) ltée.13 Dante Hardware Inc.44 Demotex inc.13 Design Globex Inc.22 92 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 janvier 1970, 102' année, u° 1 Lettres patentes Letters l'aient (suite) (continued) Distributeurs Finesse inc.20 Domaine du Lac Louise inc.(Le).14 Dromo inc.14 Dulex inc.14 Edicon Inc.15 Éditions Commerce (Les).15 Encadrements Select inc.10 Entrepreneurs I.C.M.ltée (Les).10 Entreprises André Lambert inc.(Les) .10 Entreprises Capricorne limitée (Les).17 Entreprises JEM inc.(Les).17 Entreprises La jeunesse inc.(Les).17 Entreprises Laucof inc.(Les).1S Entreprises L.P.Brosseau ltée (Les) .1S Entreprises Verdi inc.(Les).18 Equipements de Rembourrage Jolibois inc.(Les).10 Ferme du Rossignol inc.19 Festival des Cantons de l'Est inc.19 Finesse Distributors Inc.20 Foam-O-Matic Inc.20 Gareau (Paul & Bernard) inc.'.20 Gauthier & Gagnon Associés ltée.21 Gestion Abc! Plourdc ltée.21 Gibby's Steak House Inc.21 GI-RO transport inc.22 Globex Design Inc.22 Grace Dart Hospital Foundation.22 Ilargrcaves Estate Inc.23 Hcl)crt Ajustement (Jolictte) inc.23 Hôpital de Langcvin.23 Hôpital Saint-Pnul-de-Montminy.24 Hôtel Brunswick inc.24 Hôtel-Dieu de St-Pampbilc.24 Hôtel Gaspé inc.25 Houle (Paul) inc.25 I.C.M.Contractors Ltd.16 Ile Perrot Auto Parts Inc.25 Immeubles J.F.Morissctte liée (Les).26 Immeubles Linettc inc.26 Imprimerie Vagmar limitée.26 Intel-provincial Parts 70 Inc.27 Jardins de la Concorde ltée.27 Javel Concentres Inc.27 Jcn-Dro Advertising Inc.44 Jolibois Upholstering Equipment Inc.19 Jubilee Québec Holdings Limited.2S King Steer Restaurant Ltd.2S Lanthier & Langcvin inc.28 Laucof Enterprises Inc.18 Laurion & frère inc.29 Lcbcl (G.) ltée.29 Lebon et Cantin inc.29 Lefebvre (Gilles) inc.30 Librairie Polyvalente (Montréul) inc.30 Lingerie Ludo inc.30 Little Old Pub Ltd.31 Lueero Mines Ltd.31 Ludo Investments Inc.41 Lussicr-Mcssicr & associés inc.31 Lyonnais (Roger) inc.32 Maine Lumber Corporation Ltd.(The).32 Maisonncuve Cleaners Inc.37 Maltais (Martin) inc.32 Marché Benoit Lavoie inc.33 Marché Paul Beuumier ltée.33 Marie-Hélène, Boutiques d'Escompte inc.33 Ménard (Rosaire) inc.34 Mettano Paper Products Ltd.34 Meunier (Aimé) inc.34 Milair Aviation Inc.35 Mines Lueero ltée.31 Mine Silverstaek ltée.49 Mitralux Media Corp.35 Modem Decor (1969) Inc.35 Motel L'Étape inc.36 Musicair inc.36 X.J.Realty Company Ltd.36 Natha disque inc.37 Nettoyeur Citadelle inc.37 Nettoyeurs Maisonncuve inc.37 Norac Lumber ( 'o.Ltd.38 Normandie Mining Corporation Ltd.38 Norsam Inc.38 North American Personel Consultants Ltd.39 Opal Paint Inc.39 Peinture Opnle inc.39 Pelletier & associés inc.39 Phoebus Imports Inc.40 Pioneers' Valley Inc.\u2022 ¦ \u2022 55 Placements Immobiliers Duverco inc.(Les).40 Placements JVD limitée (Les).40 Placements Ludo inc.(Les).41 Placements Norman Thompson inc.(Ixs).41 Placements Rosaire Courtemanchc liée.Il Plastic inc.42 Plastic Shield Products (Canada) Inc.42 Pocart Inc.43 Pontine Protestant Home for the Aged (The).43 Prcsco ltée.43 Profit-Rama Ltd.44 Profit-Rama liée.44 Publicité Jcn-Dro inc.44 Quincaillerie Dante inc.44 Résidence Bel-Air de Buckingham inc.15 Restaurant Jardin d'Or inc.45 Restaurant Le Murie-Frnncc inc.45 Restaurant Les Bergeronnes inc.40 Revue dc l'Homme d'Affaires (Québec) inc.(U).\u2022> Sadu inc.4\" St-Michacl's St.Anthony's Catholic Community.Salon Shcppard inc.47 Scan Microsystems Limited.I.Scheffer (Louis M.) Inc.47 Scofield (Frank) Agencies Ltd.4S Secrétariat des Syndicats Nationaux dc lu Raie Inc.4* Séguin (A.) publicité inc.48 Select Picture Frames Inc.16 Sicem International incorporée.49 Silverstaek Mines Ltd.40 Simard Laveuse Service inc.49 Simoncau (Arthur) liée.50 Société dc Gestion C.E.B.inc.(Lu)- 50 Société Immobilière Stc-Foy ltée (l,u).50 Société Jeune Histoire Québec.51 Sol-Rose Investments Ltd.51 Stationnement Fleur de Lys inc.51 Studio Tempo inc.52 Super Marché Drolet inc.52 Suttcn Ski & Holiday Resort Inc.52 Swunston fleuriste inc.53 Talvin Enterprises Ltd.Tissage de Cheveux de Kénogami inc.(Le).53 Toussaint (Léonard) inc.54 Trnne Converters Limited.54 Transport Jos.Gnudet (St-Donat) inc.54 Us-Can Tool Ltd.55 Vagmar Printing Limited.26 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 3, 1970, Vol.102, No.1 93 Lettres patentes Letters Patent (suite) (continued) Vallée des Pionniers inc.55 Valueline Construction Limited.55 Voyagair inc.56 Waddell (André) Ltd.56 Waddell (André) liée.56 Wolfe Management Inc.56 Lettres patentes Supplementary supplémentaires tellers Patent Cercle Universitaire (Québec).57 Cliihougumau Lumber Limited.57 Chibougamau Lumber limitée.57 Compagnie d'Aménagement Touristique de l'Est du Québec inc.(Lu).57 Harvey & Baribcau, ltée.58 lleiplex Springs Ltd.58 Mugusins Prestige ltée.58 Photo Fashion Dress Mfg.Ltd.58 Prestige Stores Ltd.58 Salon Lavigne du Cap inc.59 Shugcr Investment Coq).59 Tanguay (J.E.) & fils, inc.59 Théâtre des Variétés inc.(Le).59 DEMANDE APPLICATION h la Législature to Legislature Syrian Greek Orthodox Church of St-Nicholas of Cannda.70 Siège social Head Office Centre Constance Lcthhridgc Centre.71 MINISTÈRES DEPARTMENTS \\flaires municipale- Municipal Affairs Mont-Lebcl, munie (Piibl.).70 Education Education Municipalité .scolaire dc: School Municipolity of Acton Vale (Dcm.-Appl.).71 Sccteur-VictoriaviUc (Dcm.-Appl.) .70 Secteur-Warwick (Dcm.-Appl.).70 Travail Labour Industrie ou metiers dc: Industry or Trades of: Coiffeurs, Trois-Rivières (Prfl.).72 Construction, Montreal (Prfl - Lcry).74 Construction, Province (Erratum).74 Hairdressers, Trois-Rivières (.Levy) .72 PROCLAMATION PROCLAMATION Loterie et courses, (Bill 86) entrée en vigueur de la Loi.76 Lotteric and Races Act, (Bill 86) coming into force of the Act.76 RÉGIE QUEBEC des marches Agricultural agricoles du Québec .Marketing Board Producteurs de bois de la Mauricic (Projet de plan conjoint).77 (iood producers of the St.Maurice Region (Draught of a joint plan).77 SOUMISSIONS TENDERS Disraeli, villc-town.79 Douville, villc-town.81 Lachine ci té-ci t.v.77 Stiilion-du-Côteau.munie.83 VENTES SALES SHÉRIFS SHERIFFS Arlhubasku Arthabaska Cuisse populaire de Victoriavillc (Lu) /\u2022.«Sinottc.1.86 Iberville Iberville Roncourt, Roy, René et Grenier r* McCraw.87 Montréal Montreal Canada Trust Compuny es Boucher et al.87 Consolidated Fund Ltd.(The) rs Ri- porlclla.88 Hampshire Realties Ltd.rs Dcsbieiis rial.88 Key Investments Ltd.rs Mignolet.89 Monast rs Assclin.89 Québec Québec Bédard vs Siraux.90 Taxes Taxes Val d'Or, villc-town.84 top*. "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.