Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 avril 1970, samedi 25 (no 17)
[" 102° ANNÉE N° 1 7 vol.102 A 2401 officielle à Québec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE Quebec, gamedi 25 avril 1970 Règlements 1e Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le (¦(lût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins ne ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime élai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, Tes intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, April 25, 1970 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be mode upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE.Québec Officiai Publither 2402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, u° 17 Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre * o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lefebvre.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 35 cents per agate line, for each version, (14 fines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st.$15 and July 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Roch Lefebvre, Québec Official Publisher.Hôtel du Gouvernement, Quebec, 30 avril 1069 33015\u20141-52 Parliament Buildings, Québec.April 30, 1969 33015- 1-52 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis No 107) Postage pnid-in-cash \u2014 Third class mutter (iiermit No.10\").Lettres patentes Letters Patent Administrateurs rue Sherbrooke ouest inc.Sherbrooke Street West Administrators Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de janvier 1970, constituant en corporation: J.-N.Laurent Dupras, gérant, 4115, Sherbrooke ouest, Montréal, Albcrte Desjardins, secrétaire, fille majeure, 1424, 95c avenue, et Jean-Marc Richer, notaire, 1, Place Laval, ces deux derniers de Laval, pour les objets suivants: Faire affuires comme compugnic de portefeuille (holding) et de placement, sous le nom de « Administrateurs rue Sherbrooke ouest inc.\u2014 Sherbrooke Street West Administrators Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlllLlPPE Bouchard.34173-0 408-1970 Agence de collection interprovinciale inc.Interprovincial Collection Agency Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour de février 1970, constituant en corporation: Clément Bédard, 24, Duchcsnay, Beauport, Jean Miron, 3404, Montpctit, tous deux administra- Administrateurs rue Sherbrooke ouest inc.Sherbrooke Street West Administrators Inc.Notice is given that under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: J.-N.Laurent Dupras, manager, 4115 Sherbrooke West, Montreal, Alberto Desjurdins, secretary, spinster of the full age of majority, 1424, 95lli Avenue, and Jean-Marc Richer, notary, 1 Place Laval, the latter two of Laval, for the following purposes: To carry on business as a holding and investment company, under the name of \"Administrateurs rue Sherbrooke, ouest inc.\u2014Sherbrooke Street West Administrators Inc.», with u total capital stock of $40,000, divided into 2,0011 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each., The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiiliite Bouchard, Deputy Minister of Financial Institvtiom, Companies and Cooperatives.34173 408-197H Agence de collection interprovincialc inc.Interprovincial Collection Agency Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Clément Bédard, 24 Duchesnay, Beauport, Jean Miron.3404 Montpetit, both administrators, Jean Bour- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 leurs, Jean Bourget, 991, Fournier, et Ean liowen, 1137, de la Barre, ces deux derniers industriels, ces trois derniers de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Exploiter une agence de collection, sous le nom de « Agence de- collection intcrprovinciale inc.\u2014 Inlerprovincial Collection Agency Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 285, rue St-.losepk est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 543-1970 Les Agences Karewells inc.Karc wills Agencies Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de février 1970, constituant en corporation: Giselle Menard, ménagère, épouse divorcée de Georges Fortin, 255, boulevard Beaconsfield, Montréal, Adolphe White, 62, rue Jean XXIII, Villeneuve, et Stephen Kowalchuk, 66, rue Red-car, Islington, province d'Ontario, ces deux derniers hommes d'affaires, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de produits alimentaires, épiceries, lait et produits laitiers et autres produits qui s'y rattachent, de toutes catégories et de toutes descriptions, sous le nom de « Les Agences Karewclls inc.\u2014 Karcwells Agencies Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 36,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 103, rue Elinslie, LaSalle, district judiciaire de Montréal.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 659-1970 Agct Finance Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: Samuel Chait, 4, Surrey Gardens, Wcstmount, David Katznclson, 5526, avenue Ashdale, Côte Suint-Luc, et Ralph Lippcr, 1550, avenue McGregor, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie de finance, sous le nom de « Aget Finance Corporation », avec un capital total de $100,000, divisé en 100,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 1315 ouest, (le Maisonneuve, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 536-1970 Arkel inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, 2403 get, 991 Fournier, and Ean Bowen, 1137 de la Barre, the latter two industrialists, the latter three of St.Foy, for the following purposes: To operate a collection agency, under the name of \"Agence de collection interprovinciale inc.\u2014 Interprovincial Collection Agency Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at 285 St.Joseph St.East, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 543-1970 Les Agences Karcwells inc.Karewclls Agencies Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Giselle Menard, housewife, wife divorced from Georges Fortin, 255 Beaconsfield Boulevard, Montreal, Adolphe White, 62 Jean XXIII Street, Villeneuve, and Stephen Kowalchuk, 66 Redcar Street, Islington, Province of Ontario, the latter two businessmen, for the following purposes: To manufacture and deal in food products, groceries, milk and milk products and kindred products of all classes and descriptions, under the name of \"Les Agences Karewells inc.\u2014 Karewells Agencies Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 36,000 common shares of the par value of $1 each and 400 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 103 Elmslic Street, LaSalle, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 659-1970 Agct Finance Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th (lay of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Samuel Chait, 4 Surrey Gardens, Westmount, David Katznel-son, 5526 Ashdalc Avenue, Côte Saint-Luc, and Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a finance company, under the name of \"Aget Finance Corporation\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 1315 de Maisonneuve West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fiiiaîicial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 536-1970 Arkel inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1970, have been issued 2404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour de février 1970, constituant en corporation: Lise Kelly, gérante, épouse de Norman Kelly, 5359, Léopold-Pouliot, Montréal-Nord, Claude-F.Archambault, et Pierre Théorêt ces deux derniers avocats, de 31, St-Jacques, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, restaurants, auberges, boulangeries, tavernes, camps et maisons de touristes et stations estivales et clubs sociaux, sous le nom de « Arkel inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 31, St-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Ac sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIIUI'pe bouchard.34173-0 058-1970 by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lise Kelly, manager, wife of Norman Kelly, 5359 Léopold-Pouliot, Montreal North, Claudc-F.Archambault, and Pierre Théoret, the latter two advocates, of 31 St-Jacques, Montreal, for the following purposes: To operate hotels, restaurants, inns, bakeries, taverns, tourist camps and homes and summer resorts and social clubs, under the name of \"Arkel inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 31 St-Jacques, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative*.34173 658-III70 Arnel Commercial Enterprises Ltd.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Clifford S.Postelnik, 405, rue Deguire, Saint-Laurent, Gérard W.Postelnik, 7355, Ostcll Crescent, Stan Cytrynbaum, 95, Roxton Crescent, Sam Wex, 21, rue Cleve, tous les quatre avocats, Benoit Gcndron, étudiant en droit, 6935, rue Dumas, tous quatre de Montréal, et Erika Hume, secrétaire, épouse de Jolin B.Hume, 1210 B, Havre des Iles, Laval, pour les objets suivants: Établir et diriger des services de consultation et de mise en marché (marketing), sous le nom de \"Arnel Commercial Enterprises Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 3465, rue Drummond, bureau 55, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, IA-Philippe Bouchard.34173 5798-1969 Arnel Commercial Enterprises Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dule the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Clifford S.Postelnik, 405 Deguire Street, Saint-Laurent, Gérard W.Postelnik, 7355 Ostell Crescent, Stun Cytrynbaum, 95 Roxton Crescent, San Wex, 21 (\"levé Street, all four advocates, Benoit Gcndron, law student, 6935 Dumas Street, all four of Montreal, and Erika Hume, secretary, wife of John It.Hume, 1210 B Havre des Iles, Laval, for the following purposes: To carry on the business of consulting and marketing services of all kinds, under the name of \"Arnel Commercial Enterprises Ltd.\", with u total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 3465 Drummond Street, suite 55, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.34173-0 5798-1 (»i0 Artemis Sportswear Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation : Dimitrios Galanis, marchand, Tassia Fuku, opérateur de machine, épouse dudit Dimitrios Galanis, tous deux de 7742A, Bloomficld, et Theodore Papadopoulos, cuisinier, 5230, Esplanade, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des marchandises pour le sport, et toutes sortes d'accessoires de sport et confectionner des vêtements de sport, sous le nom de « Artemis Sportswear Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 6345-1969 Artemis Sportswear Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Dimitrios Galanis, merchant, Tassia Faka, machine operator, wife of the said Dimitrios Galanis, both of 7742A Bloomfield, and Theodore Papadopoulos, cook, 5230 Esplanade, all three nf Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sporting goods, sports clothing and sporting equipment of all kinds, under the name of \"Artemis Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of $40,00(1.divided into 2,000 common shares of the par value of $10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 6345-19(i!> QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April SB, 1970, Vol.10S, No.17 2405 Association des Anciens et des Amis de la paroisse Notre-Dame-de-la-Défense Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Ida Mauri, 7262, Wiseman, Edna Vincelli, 6895, 2c avenue, app.8, toutes deux secrétaires, filles majeures, Pietro M.Raf-faclli, prêtre-curé, 6800, Henri-Julien, Angeline Moalli, institutrice, veuve de Henri Potvin, 7260, Wiseman, Théodorine Binda, ménagère, épouse de Emile Frechette, 8358, 9e avenue, Pietro Citti, imprimeur, 9880, Papineau, tous six de Montréal, Nicola L.Corbo, notaire, 2145, chemin Cambridge, et Ernest Rigassio, pharmacien, 370, Leacross, ces deux derniers de Mont-Royal, pour les objets suivants: Etablir et maintenir un club social pour la récréation et la détente de l'esprit et du corps de ses membres et leurs invités, sous le nom de « Association des Anciens et des Amis de la paroisse Notrc-Damc-de-Ia-Défensc ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation est 6800, rue Henri-Julien, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-d 6331-1969 Association des Anciens et des Amis de la paroisse Notre-Dame-de-la-Défense Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Ida Mauri, 7262 Wiseman, Edna Vincelli, 6895, 2nd Ave., Apt.8, both secretaries, spinsters of the full age of majority, Pietro M.Raffaelli, priest-rector, 6800 Henri-Julien, Angeline Moalli, teacher, widow of Henri Potvin, 7260 Wiseman, Théodorine Binda, housewife, wife of Emile Frechette, 8358, 9th Ave., Pietro Citti, printer, 9880 Papineau, all six of Montreal, Nicola L.Corbo, notary, 2145 Cambridge Road, and Ernest Rigassio, pharmacist, 370 Leacross, the latter two of Mount Royal, for the following purposes: To establish and maintain a social club for the mental and physical amusement and relaxation of its members and their guests, under the name of \"Association des Anciens et des Amis de la paroisse Notre-Dame-de-la-Défense\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation is at 6800 Henri-Julien St., Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piuuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6331-1969 Association des Residents du Lac Blanc, inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Louis Lamoureux, 10581, (grande-Allée, Yvon Brizard, 1100, McGregor, ¦710, André Dcslongchamps, 12215, Le Mesu-rier, Guy Duranleau, 3825, St-Dcnis, tous quatre avocats, Jacques Lamoureux, étudiant, 7136, de I.orimier, Rhéa Goudreau, secrétaire, épouse de Jean Campcau, 6402, Louis-Dupiré, Diane Champagne, secrétaire, épouse de Michel Vandal, 6037, boulevard Rosemont, Murielle Pyotte, secrétaire, épouse de Jose-Antonio Gonzales, 3S03, Sherbrooke est, tous huit de Montréal, François Boisclair, avocat, 702, Hartland, Outrc-niont, Jcannine Houdc, secrétaire, épouse Marcel Calai, 5855, Charmcnil, Pierrette Paquin, secrétaire, épouse de Jean-Paul Couture, 6319, Cham-hois, toutes deux de Saint-Léonard, Denise Coulure, secrétaire, épouse de Claude Denis, 977, Davion, Longueuil, Lise Rivest, secrétaire, fille majeure, 147, de l'Église, L'Assomption, Normande Brochu, secrétaire, fille majeure, 110, de N'ormandie, Boucherville, et Diane Jodoin, secrétaire, fille majeure, 10936, Armand Lavergne, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts culturels et sociaux des membres, sous le nom de « Association des Résidents du Lac Blanc, inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Association des Résidents du Lac Blanc, inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jean-Louis Lamoureux, 10581 Grande-Allée, Yvon Brizard, 1100 McGregor, #710, André Dcslongchamps, 12215 Le Mesurier, Guy Duranleau, 3825 St-Denis, all four advocates, Jacques Lamoureux, student, 7136 de Lorimier, Rhéa Goudreau, secretary, wife of Jean Campeau, 6402 Louis-Dupiré, Diane Champagne, secretary, wife of Michel Vandal, 6037 Rosemont Blvd., Murielle Pyotte, secretary, wife of Jose-Antonio Gonzalez, 3803 Sherbrooke east, all eight of Montreal, François Boisclair, advocate, 702 Hartland, Outremont, Jean-nine Houde, secretary, wife of Marcel Gala], 5855 Charmenil, Pierrette Paquin, secretary, wife of Jean-Paul Couture, 6319 Chambois, both of Saint-Léonard, Denise Couture, secretary, wife of Claude Denis, 977 Davion, Longueuil, Lise Rivest, secretary, spinster of the full age of majority, 147 de l'Église, L'Assomption, Normande Brochu, secretary, spinster of the full age of majority, 110 de Normandie, Boucherville, and Diane Jodoin, secretary, spinster of the full age of majority, 10936 Armand Lavergne, Montreal North, for the following purposes: To promote the cultural and social interests of the members, under the name of \"Association des Résidents du Lac Blanc, inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $100,000. 2406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n° 17 Le siège social de la corporation est à Notrc-I)ame-de-Ia-Merci, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 6233-69 L'association récréative et culturelle de Cléricy (L'Arc de Cléricy) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: John Beaulicu, contremaître, Yvon Goulet, chauffeur, David Girard, cantonnier, et Marcel Ménard, professeur, tous de Cléricy, pour les oh jets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de * L'association récréative et culturelle de Cléricy (L'Arc de Cléricy) >.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social de la corporation est à Cléricy, district judiciaire de Rouyn-Noranda.Iœ sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-o 4936-1969 Assurances P.Louis Lepage liée lx ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en cori>ora-tion: Roger Parenteau, avocat, 1450, Frudct, Drummondville-Sud, Pierre-Louis Lepage, agent d'assurance, 545, Fontainebleau nord, Longueuil, et Jacques Lepage, professeur, 3080, rue Allen, Verdun, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers et agents en assurance, sous le nom de < Assurances P.I .oui-.I-epage ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Ia: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 5868-1969 Les ateliers audio-visuels du Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de février 1970, constituant en corporation: Bernard Faribault, 175, boulevard Dcguirc, app.1415, Saint-Laurent, Jean-Pierre Mongeau, 426, avenue Elm, Westmount, et J.-Édouard Isabelle, 100, Gaspé, app.711, Verdun, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme producteurs et éditeurs île projections animées et de produits audiovisuels et exploiter des ateliers de projections animées, sous le nom de « Les ateliers audiovisuels du Québec», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $20 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.The head office of the corporation is at Xotre-Dame-dc-la-Mcrci, judicial district of Joliette.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial hislilulions, Companies and Cooperatiees.34173 6233-1)9 L'association récréative et culturelle de Cléricy (L'Arc de Cléricy) Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: John Beaulieu, foreman, Yvon Goulct, chauffeur, David Girard, road-surveyor, and Marcel Ménard, professor, all of Cléricy, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"L'association récréative et culturelle de Cléricy (L'Arc de Cléricy)\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to l>e limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Cléricy, judicial district of Rouyn-Noranda.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatiees.34173 4936-1909 Assurances P.Louis Lepage liée Notice is given that under Port I of the Companies Act, letters patent, bearing dutc the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Parenteau, advocate, 1450 Fraud, Drummond-ville South, Pierre-Louis l/cpagc, insurance ageid, 545 Fontainebleau north, Longueuil, and Jacques l^page, professor, 3080 Allen St., Verdun, for the following purposes: To carry on business as insurance brokers and agents, under the name of \"Assurances P.Louis Lepage ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of $10 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Longueuil.judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5868-19li!l Les ateliers audio-visuels du Québec Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Faribault, 175 Dcguirc Blvd., Apt.1415, Saint -Laurent, Jean-Pierre Mongeau, 426 Elm Ave.Westmount, and J.-Édouard Labelle, 100 Gaspé.Apt.711, Verdun, all three advocates, for the following purposes: To act as producers and editors of motion pictures and of audio-visual effects, and to operate motion picture work-shops, under the name of \"Les ateliers audio-visuels du Québec\"', with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common sliares of $20 ench and 200 preferred shares of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2407 Le siège social de la compagnie est 239, boulevard Deguire, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 53-1970 Avimal inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Vincenzo Mattii, imprimeur, Andrée Forand, secrétaire, épouse dudit Vincenzo Mattii, tous deux de 3375, Edouard Montpetit, suite 502, Montréal, et Italo Cappclli, imprimeur, 2750, DcBlois, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et autres commerces semblables, sous le nom de « Avimat inc.», avec un capital tolal de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune._ Le siège social de la compagnie est 3375, Fdouard, Montpetit, suite 502, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratiecs, Ls-Philippe Bouchard.31173-0 426-1970 B.D.& E.Marketing Agency Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour de janvier 1970, constituant en corporation : Harry Blonk, 4625, Miller, Sol B.Apcl, 2657, F.kers, tous deux de Montréal, et Irving Adessky, ôli, Heath, Hampstead, tous trois avocats, pour les objets suivants: Aider à la mise en marché de toutes sortes de produits et s'établir compagnie de placements, sous le nom de « B.D.& E.Marketing Agency Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3.000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est n Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Puilippe Bouchard.31173 441-1970 Jacques Barrette inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jacques Barrette, journaliste, Nicole Gouin, ménagère, épouse dudit Jacques Barrette, tous deux de 29, Glencoe, Outremont, et Yvan Guérin, comptable agréé, 715, Hocquart, Laval, pour les objets suivants: Exploiter une entreprise de publicité par le truchement de la radio, de la télévision, de films, de photographies, de matières imprimées ou de toute autre manière, sous le nom de « Jacques Barrette inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale «le 810 chacune.The head office of the company is at 239 Deguire Blvd., Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 53-1970 Avimat inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Vincenzo Mattii printer, Andrée Forand, secretary, wife of the said Vincenzo Mattii, both of 3375 Edouard Montpetit, suite 502, Montreal, and Italo Cappelli, printer, 2750 DcBlois, Laval, for the following purposes: To carry on business as publishers, printers, engravers, book-binders and in other similar trades, under the name of \"Avimat.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 3375 Edouard Montpetit, suite 502, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 426-1970 B.D.& E.Marketing Agency Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Harry Blank, 4625 Miller, Sol B.Apel, 2657 Ekcrs, both of Montreal, and Irving Adessky, 56 Heath, Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To assist in the marketing of all kinds of products and to act as an investment company, under the name of \"B.D.& E.Marketing Agency Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 441-1970 Jacques Barrette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Barrette, journalist, Nicole Gouin, housewife, wife of the said Jacques Barrette, both of 29 Glencoe, Outremont, and Yvan Guérin, chartered accountant, 715 Hocquart, Laval, for the following purposes: To operate an enterprise advertising on radio, television, in films, photographs, printed matter or by any other means, under the name of \"Jacques Barrette inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of $1 each and 3,500 preferred shares of a nominal value of $10 each. 2408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I-e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 363-1970 Bas Valérie inc.Valeric Hosiery Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 3e jour de février 1970, constituant en corporation : Guy Lachance, agent-manufacturier, 7803, Place Chambon, Anjou, Walter Mudry, teinturier, 125, Filion, Laval, et Roland Létourneau, voyageur de commerce, 5132, Mentana, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de vêtements, lingerie, toile, coton, laine, nylon et tissus de toutes sortes, sous le nom de « Bas Valérie inc.\u2014 Valerie Hosiery Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et en 380 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 7803, Place Chambon, Anjou, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 40-1970 L.Bédard & associés limitée L.Bédard & Associâtes Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de février 1970, constituant en corporation: Léo Bédard, ingénieur, Lise Caron, ménagère, épouse dudit Léo Bédard, tous deux de Browns-burg, et Louis-Philippe Galipeau, avocat, 739, Principale ouest, Magog, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers en immeuble, sous le nom de « L.Bédard & associés limitée \u2014 L.Bédard & Associates Limited », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Browns-burg, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 244-1970 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 363-1970 Bas Valérie inc.Valeric Hosiery Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Lachance, manufacturer's agent, 7803 Place Chambon, Anjou, Walter Mudry, dyer, 125 Filion, Laval, and Roland Létourneau, commercial traveller.5132 Mentana, Montreal, for the following purposes: To deal in clothing, lingerie, linen, cotton, wool, nylon and woven materials of all kinds, under the name of \"Bas Valérie inc.\u2014 Valerie Hosiery Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of S10 each and 380 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 7803 Place Chambon, Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 40-1970 L.Bédard & associés limitée L.Bédard & Associates Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Fiancial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Léo Bédard, engineer.Lise Caron, housewife, wife of the said Léo Bédard, both of Bronwsburg.and Louis-Philippe Galipeau, advocate, 7311 Main St.West, Magog, for the following purposes: To carry on business as real estate brokers, under the name of \"L.Bédard & associés limitée \u2014 L.Bédard & Associates Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,0011 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Brown-burg, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 244-197(1 Bédard, Lavoie & Lessard inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Roger Lavoie, 855, du Coteau, Jean Bédard, 2742, Louisbourg, et Maurice Lessard, 682, Suète, tous trois représentants, de Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme bijoutiers, orfèvres, marchands de diamants et fabricants de montres, sous le nom de « Bédard, Lavoie & Lessard inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Bédard, Lavoie & Lessard inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Lavoie, 855 du Coteau, Jean Bédard, 2742 Louisbourg, and Maurice Lessard, 682 Suète, all three representatives, of St.Foy, for the following purposes: To carry on business as jewellers, goldsmith-, diamond merchants, and watch-makers, under the name of \"Bédard.Lavoie & Lessard inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shores of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2409 Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.31173-0 6208-1969 Bélanger Autorama liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: .1 .-Eugène Bélanger, commerçant, Annette Dostie, ménagère, épouse dudit J.-Eugène Bélanger, tous deux de 136, Tuppcr, et Rolland Lavallée, gérant, rurale numéro 4, tous trois de Magog, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Bélanger Autorama ltée », avec un capital total de £200,000, divisé en 1,950 actions ordinaires de $100 chacune et en 5,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Magog, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 6303-1969 Bélanger & Blanchettc ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de février 1970, constituant en corporation: Roland Bélanger, industriel, Jeannine St-Pierrc, ménagère, épouse dudit Roland Bélanger, tous ilcux de 2175, boulevard Mercure, Gilles Bélisle, comptable, 170 B, Des Peupliers, tous trois de Drummondville, Clément Blanchettc, industriel, et Andréa Bélanger, ménagère, épouse dudit Clément Blanchettc, ces deux derniers de 2602, boulevard Mercure, Saint-Nicéphore, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous produits, articles et marchandises fabriqués totalement ou en partie de métaux, bois, plastique et carton, sous le nom île * Bélanger & Blanchettc ltée », avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Nicéphore, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.34173-0 507-1970 The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6208-1969 Bélanger Autorama ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: J.-Eugène Bélanger, trader, Annette Dostic, housewife, wife of said J.-Eugène Bélanger, both of 136 Tupper, and Rolland Lavallée, manager, Rural Route number 4, all three of Magog, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers, and to deal in automobiles, motors, machines and all their parts and accessories, under the name of \"Bélanger Autorama ltée\", with a total capital stock of $200,000, divided into 1,950 common shares of $100 each and 5,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Magog, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6303-1969 Bélanger & Blanchette ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roland Bélanger, industrialist, Jcannine St-Pierre, housewife, wife of said Roland Bélanger, both of 2175 Mercure Boulevard, Gilles Bélisle, accountant, 170 B Des Peupliers, all three of Drummondville, Clément Blanchettc, industrialist, and Andréa Bélanger, housewife, wife of said Clément Blanchette, the latter two of 2602 Mercure Boulevard, Saint-Nicéphore, for the following purposes: To deal in all products, articles and merchandise manufactured totally or partially in metal, wood, plastic and cardboard, under the name of \"Bélanger & Blanchettc ltée\", with a capital stock divided into 10,000 common shares without nominal value and into 5,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Saint-Nicéphore, judicial district of Drummond.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 507-1970 Bonavcnlurc 2102 Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Gerald McCarthy, avocat, 4, place Ville-Marie, bureau 514, Montréal, Valerie Jean Higgins, 50, avenue Hudson, Mont-Royal, et Céline Trudeau, 2132, rue Bossuet, Montréal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, poulies objets suivants: Bonavcnture 2102 Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gerald McCarthy, advocate, 4 Place Ville Marie, Suite 514, Montreal, Valerie Jean Higgins, 50 Hudson Avenue, Mount Royal, and Céline Trudeau, 2132 Bossuet Street, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: 2410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 86 avril 1970, 108' année, n° 17 Exercer les affaires d'une compagnie de placements, sous le nom de « Bonaventure 2102 Ltd.», avec un capital-actions divisé en 5,000,000 d'actions ordinaires sans valeur au pair.I.e siège social de la compagnie est 4, place Ville-Marie, bureau 514, Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 310-1970 Boutique de créations pour enfants Rachel inc.Rachel Children's Creations Boutique Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date «lu 9c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Rachel Dion, célibataire, Gabrielle Dion, veuve d'Edouard Dion, toutes deux du 6509, Papineau, Montréal, et Gérard Côté, 7634, Rollin, Saint-Léonard, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de produits, articles et marchandises de toutes sortes, sous le nom de « Boutique de créations pour enfants Rachel inc.\u2014 Rachel Children's Creations Boutique Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 112-1970 Brasserie La Chaudière inc.Le ministre des institutions financières, compa-pagnics et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de février 1970, constituant en corporation: J.-Hcrvé A.Bouchard, marchand, Bernadette Tremblay, ménagère, épouse dudit J.-Hervé A.Bouchard, et André Bouchard, marchand, tous trois de 135, St-Gcorges, Lévis, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Brasserie La Chaudière inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 137, rue .St-Gcorges, Lévis, district judiciaire de Québec.L» sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 577-1970 lin uni \\ inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de février 1970, constituant en corporation: Richard Drouin, 1780, Côte Gignac, Sillery, Alphonse Laçasse, 3339, rue Hertel, tous deux avocats, et René Gauthier, courtier, 3833, chemin St-Louis, ces deux derniers de Sainte-Foy, pour les objets suivants: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Bonaventure 2102 Ltd.\", with a capital stock divided into 5,000,0011 common shares without par value.The head office of the company is at 4 Place Ville Marie, Suite 514, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 310-19711 Boutique de créations pour enfants Rachel inc.Rachel Children's Creations Boutique Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Rachel Dion, spinster, Gabrielle Dion, widow of Edouard Dion, both of 6509 Papineau, Montreal, and Gérard Côté, 7634 Rollin, Saint-Léonard, all three executives, for the following purposes: To manufacture and deal in products, goods, wares and merchandise of every kind, under the name of \"Boutique de créations pour enfants Rachel inc.\u2014 Rachel Children's Creations Boutique Inc.\", with a total capital stock of 140,000, divided into 20,000 common shares of 81 each and 20,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 112-1970 Brasserie Lu Chaudière inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of February, 1970, have l>ecn issued by tin-Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: J.-Hervé A.Bouchard, trader, Bernadette Tremblay, housewife, wife of said J.-Hervé A.Bouchard, and André Bouchard, trader, all three of 135 Sl-Gcorges, Levis, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Brasserie La Chaudière inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company is at 137 Si-Georges Street, Levis, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 577-19711 Itrciivex inc.Notice is given that under Part I of tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Drouin, 1780 Côte Gignac, Sillery, Alphonse Laçasse, 3339 Hertel Street, both advocates, and René Gauthier, broker, 3833 St-Louis Road, the latter two of St.Foy, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2411 Faire le commerce d'aliments, liqueurs, vins, bières et autres breuvages alcooliques ou non, sous le nom de * Breuvex inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 500 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.34173-o 557-1970 Brigitte Haute Coiffure inc.\\x ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Adrien Bordua, avocat, 1770, Prieur est, Montréal, Monique Moquin, 646, St-Pierre, Chambly, cl Rolande Raymond, 8165, Alvcrnc, Saint-Léonard, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter un ou des salons de coiffure, de l>eauté et d'esthétique, sous le nom de « Brigitte Haute Coiffure inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $1 chacune et en 300 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.I* siège social de la compagnie est 35, boulevard d'Argcnson, Repentigny, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppe Bouchard.34173-o 259-1970 C J M D inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de février 1970, constituant en corporation: Jean-Marie Duchainc, directeur de production, Carmen Duchainc, agent de voyage, épouse dudit Jean-Marie Duchainc, tous deux de 538, boulevard Walbcrg, et Maurice Dion, gérant, 135, lrc avenue, tous trois de Dolbeau, pour les objets suivants: Entretenir et exploiter les postes émetteurs et récepteurs de radiodiffusion et de T.S.F., sous le nom de « C J M D inc », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune Le siège social de la compagnie est à Dolbeau, district judiciaire de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 584-1970 CL.électrique inc.Ia- ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Claude Lachance, entrepreneur-électricien, Gisèle Marcotte, ménagère, épouse dudit Claude Lachance, tous deux de 9, rue St-Jean, Xcuf-cliatcl, et Michel Côté, comptable, 2100, 25c rue, Québec, pour les objets suivants: To deal in food products, liquor, wines, beer and other alcoholic or non-alcoholic beverages, under the name of \"Breuvex inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 5,000 common shares of $10 each and into 500 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 557-1970 Brigitte Haute Coiffure inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Adrien Bordua, advocate, 1770 Prieur Street East, Montreal, Monique Moquin, 646 St-Picrrc, Chambly, and Rolande Raymond, 8165 Alverne, Saint-Léonard, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To operate one or several hairdrcssing, beauty and aesthetical parlors, under the name of \"Brigitte Haute Coiffure inc.\", with a total capital of $40,000, divided into 10,000 common shares of a nominal value of $1 each and 300 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 35 d'Argcnson Boulevard, Repentigny, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 259-1970 C J M D inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Mane Duchainc, production director, Carmen Duchainc, travel agent, wife of said Jean-Marie Duchainc, both of 538 Walberg Boulcvrd, and Maurice Dion, manager, 135,1st Avenue, all three of Dolbeau, for the following purposes: To maintain und operate radio and wireless broadcasting and receiving stations, under the name of \"C J M D inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Dolbeau, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 584-1970 CL.électrique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude La-chance, electrical contractor, Gisèle Marcotte, housewife, wife of the said Claude Lacliancc, both of 9 St-Jcan St., N'cufchatcl, and Michel Côté, accountant, 2100, 25th St., Québec, for the following purposes: 2412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 85 avril 1970, 108' année, n\" 17 Faire affaires comme électriciens et faire l'entretien et le commerce d'appareils électriques de toutes sortes, sous le nom de « C.L.Électrique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 9, rue St-\u2022leun, Ncufchatel, district judiciaire de Québec.Ac sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ia-Philippe Bouchard.34173-Ô 209-1970 CRM Capital Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Michael P.Maloncy, 445, avenue Lepage, app.102, Dorval, Farid A.Chcftechi, 6950, avenue Fielding, app.615, et John Hamilton junior, 5820, rue Louisbourg, app.26, ces deux derniers de Montréal, tous trois commis en loi, pour les objets suivants:, Fabriquer, vendre et écouler des métaux ou minéraux tels que l'aluminium, le sodium, le fer, sous le nom de « CRM Capital Limited », avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur au pair.I«c siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIII.ippe bouchahd.34173 85-1970 Camp-École Chicobi Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Fernand Miron, 233, rue Demers, Pierre Martineau, 3755, Linton, app.6, tous deux étudiants, de Montréal, et J.-Edmond Gagnon, avocat, 3935, Victoria, Lachinc, pour les objets suivants: Exploiter un camp-école et former des clubs de sciences naturelles, organiser des expositions régionales, des conférences et autres activités destinées à promouvoir les sciences naturelles, sous le nom de « Camp-École Cliicobi Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social de lu cori>oration est à Guyenne, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 133-1970 Candy Sportswear Ltd.I.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Irving Swersky, manufacturier, 7920, chemin Wavcll, Samuel Moscovitch, avocat, 5564, avenue Alpine, tous deux de Côte Saint-Luc, et Lia Larocque, secrétaire, célibataire, 423, rue Mayor, bureau 2, Montréal, pour les objets suivants: To carry on business as electricians, and to repair and deal in all kinds of electrical appliances, under the name of \"C.L.électrique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 9 Sl-Jcan St., Ncufchatel, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 209-1970 CRM Capital Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michael P.Maloncy, 445 I/cpage Avenue, Apt.102, Dorval.Farid A.Chcftechi, 6950 Fielding Avenue, Apt.615, and John Hamilton junior, 5820 Ixniishourg Street, Apt.26, the latter two of Montreal, nil three law clerks, for the following purposes: To manufacture, sell and dispose of aluminum, sodium, iron or other metals or minerals, under the name of \"CRM Capital Limited\", with a capital stock divided into 1,000 shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 85-197(1 Camp-École Chicohi Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without sliare capital: Fcrnand Miron, 233 Demcrs Street, Pierre Martineau, 3755 Linton.Apt.6, both students, of Montreal, and J.-Edmond Gagnon, advocate, 3935 Victoria, Lachinc, for the following purposes: To operate a school camp and form natural science clubs, organize regional exhibitions, lectures and other activities in order to promote natural sciences, under the name of \"Camp-École Chicobi Inc.\".The amount to which is limited the value of 'the immovable property that the corporation may acquire and hold is $50,000.The head office of the corporation is at Guyenne, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 133-1970 Candy Sportswear Ltd.Notice is given tliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving Swersky, manufacturer, 7920 Wavcll Road, Samuel Mosko-vitch, advocate, 5564 Alpine Avenue, both of Côte Saint-Luc, and Ida Larocque, secretary, spinster, 423 Mayor Street, Suite 2, Montreal, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 Confectionner des vêtements sport, vêtements et articles vestimentaires en faire le commerce, sous le nom de « Candy Sportswear Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,500 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.14173 325-1970 Capitol Automobile Inc.Le ministre des institutions financières, compa-pagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: David M.Notkin, Leslie I.Notkin, tous deux avocats, du 3742, The Boulevard, Westmount, et Ethel Wener, programmeur, célibataire, 5763, chemin de la Côte St-Luc, app.9, Hampstead, l>our les objets suivants: S'établir garagistes et fabriquer, acheter, vendre et réparer automobiles, camions, tracteurs, motocyclettes et véhicules moteurs de toutes sortes, ainsi que les accessoires et pièces qui s'y rattachent, sous le nom de « Capitol Automobile Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de $100 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur nu pair de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 4005 est, rue Jean-Talon, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 9-1970 Curih-Canadn Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation: -lohn George Gibson, administrateur immobilier, 100 sud, avenue Brock, Montréal-Ouest, Gordon Leonard McGilton, avocat, 636, avenue Belmont, Westmount, et Miriam Bernstein, secrétaire, épouse de David Burash, 1755, avenue North, (jutremont, pour les objets suivants: S'établir compagnie de transport, sous le nom île * Carib-Canada Corp.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 , 338-1970 Le Centre de Mécanique Industrielle Marquis & Faucher inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Léonard Marquis, gérant, Roselle Aubin, ména- 2413 To manufacture and deal in sportswear, clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Candy Sportswear Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5,000 common shares of a par value of $1 each and 3,500 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, .Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 325-1970 Capitol Automobile Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, liave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coopratives, incorporating: David M.Notkin, IajsHc I.Notkin, both advocates, of 3742 The Boulevard, Westmount, and Ethel Wener, programmer, spinster, 5763 Côte St.Luc Road, Apt.9, Hampstead, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to manufacture, deal in and repair automobiles, trucks, tractors, motorcycles, and motor vehicles of all kinds and the accessories and parts thereof, under the name of \"Capitol Automobile Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of the par value of $100 each and 300 preferre shares of the par value of $100 each.The head office of the company is at 4005 Jean Talon Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 9-1970 Carib-Canada Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John George Gibson, estate administrator, 100 Brock Avenue South, Montreal West, Gordon I.eonard McGilton, advocate, 636 Belmont Avenue, Westmount, and Miriam Bernstein, secretary, wife of David Barash, 1755 North Avenue, Outre-inout.for the following purposes: To carry on the business of a transportation company, under the name of \"Carib-Canada Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $1 each and 3,900 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 338-1970 Lc Centre de Mécanique Industrielle Marquis & Faucher inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Léonard Marquis, manager, Roselle Aubin, housewife, wife of 2414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n\" 17 gère, épouse dudit Léonard Marquis, tous deux de rue Ste-Madelcine, Louis Faucher, machiniste, et Edith Chassé, ménagère, épouse dudit Louis Faucher, ces deux derniers de boulevard Vachon, tous quatre de Sainte-Marie, pour les objets suivants: Faire le commerce et la réparation d'appareils électriques, machineries, instruments, équipements agricoles, forestiers, ou miniers et autres accessoires connexes, sous le nom de « Le Centre de Mécanique Industrielle Marquis & Faucher inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30;000 actions ordinaires de $1 chacune et en 10,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Marie, district judiciaire de Beauce.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 4998-1969 Centre de Radio de Magog inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: Raymond Bertrand, technicien, Yolande Brous-seau, secrétaire, épouse dudit Raymond Bertrand, tous deux de 209, St-Patricc est, et Albert Brousseau, journalier, 119, Tupper, tous trois de Magog, pour les objets suivants: Faire le commerce de tous appareils, articles, machines, outillages, dispositifs, accessoires employés dans la réception ou la transmission par les airs d'images et sons de toutes sortes, sous le nom de * Centre de Radio de Magog inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Magog, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 165-1970 said Léonard Marquis, both of Ste-Madelcine Street, Louis Faucher, machinist, and Edith Chassé, housewife, wife of said Louis Faucher, the latter two of Vachon Boulevard, all four of Sainte-Marie, for the following purposes: To deal in and repair electricial appliances, machinery, instruments, farm, forestry or mining equipment and other accessories related thereto, under the name of \"Le Centre de Mécanique Industrielle Marquis & Faucher inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 30,000 common shares of $1 each and into 10,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Sainte-Marie, judicial district of Beauce.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 4998-1969 Centre de Radio dc Magog inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Bertrand, technician, Yolande Brousseau, secretary, wife of said Raymond Bertrand, both of 209 St-Patricc East, and Albert Brousseau.labourer, 119 Tupper, all three of Magog, for the following purposes: To deal in all appliances, articles, machines, tools, devices and accessories used in the receiving and transmission by air of pictures and sounds of all kinds, under the name of \"Centre de Radio de Magog inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Magog, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 165-1970 Centre dc Vinyl Métropolitain ltée Metropolitan Vinyl Center Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Pierre Grenier, 6307, De Blainville, Serge Lepage, 5884, Chardin, John Joseph Capocci, 84477, Bonnivet, tous trois de Saint-Léonard, et Fernand Rochon, 4242, Prince Charles, Laval, tous quatre vendeurs, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de vinyl, aluminium et autres métaux, de bois, verre, matières plastiques et autres matières ou de n'importe quelle combinaison de matières, sous le nom dc « Centre de Vinyl Métropolitain ltée \u2014 Metropolitan Vinyl Center Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 418-1970 Centre de Vinyl Métropolitain ltée Metropolitan Vinyl Center Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, liave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Grenier, 6307 De Blainville, Serge Lepage, 5884 Chardin.John Joseph Capocci, 84477 Bonnivet, all three of Saint-Léonard, and Fernand Rochon, 4242 Prince Charles, Laval, all four salesmen, for the following purposes: To manufacture and deal in vinyl, aluminum or other metals, wood, glass, plastics or other materials or any combination of materials, under the name of \"Centre de Vinyl Métropolitain ltée \u2014 Metropolitan Vinyl Center Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of the par value of $1 each and 20,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 418-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 Centre récréatif dc Blainvillc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Claude Gagné, mécanicien, 83, Bruchési, Jean Fcrreault, assembleur, 83, Martin, tous deux de Sainte-Thérèse, et \u2022Ican-Cloude Matte, camionneur, 456, Montrose, route rurale 1, Roscmère, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif, sous le nom de « Centre récréatif dc Blainvillc inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $40,000.Le siège social de la corporation est 83, rue Bruchési, Sainte-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne.Lesous-minislrc des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.31173-0 6286-1969 Centre Récréatif dc Coteau Station Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé ties lettres patentes, en date du 2e jour dc février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Ménard Ru vary, wagonnier, Léo Bruncuu, commis de bureau, Anita Couture, ménagère, épouse dc Guy Couture, Hermès Walker, marchand, Gilles Guerrier, inspecteur, Rock Forticr, contremaître, et Léo Richer, serre-freins, tous de La Station-du-Coteau, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de < Centre Récréatif de Coteau Stution ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation est à La Station-du-Coteau, district judiciaire dc Montréal.I* sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 306-1970 Chalac inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Denis Chabot, électricien, Rachel Chrétien, ménagère, épouse dudit Denis Chabot, tous deux de 31, Notre-Damc-de-Fatima, Lorctteville, Eugène Lachance, mécanicien, et Charlotte Paquet, ménagère, épouse dudit Eugène Lachance, ces deux derniers dc 15, rue Victoria, Saint-Emile, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction, sous le nom de « Chalac inc.-» avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 447-1970 2415 Centre récréatif de Blainville inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, liave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Claude Gagné, mechanic, 83 Bruchési, Jean Pcrrcault, assembler, 83 Martin, both of Sainte-Thérèse, and Jean-Claude Matte, trucker, 456 Montrose, Rural Route 1, Roscmère, for the following purposes: To form and operate a sports club under the name of \"Centre récréatif de Blainville inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $40,000.The head office of the corporation is at 83 Bruchési Street, Sainte-Thérèse, judicial district of Terrebonne.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6286-1969 Centre Récréatif de Coteau Station Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Ménard Ravary, waggoneer, Léo Bruncau, office clerk, Anita Couture, housewife, wife of Guy Couture, Hermès Walker, trader, Gilles Cucrrier, inspector, Rock Fortier, foreman, and Léo Richer, brakeman, all of Coteau Station, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"Centre Récréatif de Coteau Station\".The amount to which is limited the immovable \u2022property which the corporation may acquire and possess is $100,000.The head office of the corporation is at Coteau Station, judicial judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 306-1970 Chalac inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denis Chabot, electrician, Rachel Chrétien, housewife, wife of said Denis Chabot, both of 31 Notrc-Damc-dc-Fatima, Lorctteville, Eugène Lachance, mechanic, and Charlotte Paquet, housewife, wife of said Eugène Lachance, the latter two of 15 Victoria Street, Saint-Émilc, for the following purposes: To carry on business as general building contractors, under the name of \"Chalac inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each nnd 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Finaîicial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 447-1970 2416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Chaton Bleu inc.Le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jacques Champagne, courtier d'assurance, 10739, Grandc-Alléc, Louise liaribeau, secrétaire, fille majeure, 3063, Bossuet, tous deux de Montréal, et Yvonne Ducharmc, rentière, fille majeure, 445, boulevard St-Joseph ouest, appartement 18, Outremont, pour les objets suivants: Faire affaires comme hôteliers, aubergistes et restaurateurs, sous le nom de « Chaton Bleu inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint Hippolytc, district judiciaire dc Terrebonne.Le sous-ministre dc.i institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 179-1970-o Chaton Bleu inc.Notice is given that under Part I of tin-Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Champagne, insurance broker, 10739 Grande-Alice.Louise Baribeau, secretary, spinster of the full age of majority, 3063 Bossuet, both of Montreal, and Yvonne Ducharmc, annuitant, spinster of the full age of majority, 445 St-Joseph Boulevard West, Apartment 18, Outrcmont, for the following purposes: To carry on business as hotel-keepers, innkeepers and restaurant-keepers, under the name of \"Chaton Bleu inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $1(1 each.The head office of the company is at Saint-Hippolyte, judicial district of 'I errebonne.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 179-19711 Christine Pizza Inc.lx ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1970, constituant en corporation: N'ikolaos Samaras, coupeur, Konstantino Samaras, et Ioannis Samaras, ces deux derniers cuisiniers, tous trois du 4841, Jeanne-Mance, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des buffets, petits restaurants, buffets laitiers, restaurant, salons de thé, cafétérias et Snack-bars, sous le nom de « Christine Pizza Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 200 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 4841, Jeanne-Mance, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 137-1970 Ciné-parc route 9 inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de févrir 1970, constituant en corporation: Gérard Corbcil, avocat, Pierre Corbcil, régisseur de théâtre, tous deux de 394, rue de Maricourt, Longueuil, et Claire LaPlante, secrétaire, épouse dc Claude Mallette, 2785, rue Beaujolais, Brassard, pour les objets suivants: Exploiter des cinémas, ciné-parcs, théâtres, et autres lieux dc spectacle et d'amusement, sous le nom dc « Ciné-parc route 9 inc.», avec un capital total de $130,000, divisé en 3,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 10,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 6, avenue Melrose, Dclson, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 563-1970 Christine Pizza Inc.Notice is given that under Part I of tin Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nikolaos Samaras, cutter, Konstantino Samaras, and Ioannis Samaras, the latter two cooks, all three of 4841 Jcannc-Mance, Montreal, for the following purposes: To operate refreshment rooms, lunch rooms, dairy lunch rooms, restaurant, tea rooms, coffee rooms, cafétérias ami sandwich bars, under the name of \"Christine Pizza Inc.\", with a total capital stock of $40.000, divided into 2,0011 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 4S4I Jeanne Mance, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 137-1970-.Ciné-parc route 9 inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Corbeil, advocate, Pierre Corbcil, theatre manager, both of 394 de Maricourt St., Longueuil.and Claire LaPlante, secretary, wife of Claude Mallette, 2785 Beaujolais St., Brassard, for the following purposes: To operate cinemas, drive-in theatres, theatres and other places of entertainment, under the name of \"Ciné-parc route 9 inc.\", with a total capital stock of $130,000,dividcd into 3,000 common shares of $10 each and 10,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is ut 6 Melrose Ave., Delson, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 563-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 86, 1970, Vol.108, No.17 2417 Claubert inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: Marcel-G.Guilbault, avocat, Louise Bourdon, secrétaire, fille majeure, et Louis Payette, notaire, tous trois de 159, rue Craig ouest, suite 719, Montréal, pour les objets suivunts: Faire le commerce de vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures, articles en cuir et articles divers, sous le nom de « Claubert inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.31173-0 144-1970 Claubert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel-G.Guilbault, advocate, Louise Bourdon, secretary, spinster of the full age of majority, and Louis Payette.'notary, all three of 159 Craig St.West, Suite 719, Montreal, for the following purposes: To deal in clothing, clothing accessories, footwear, leather articles and miscellaneous articles, under the name of \"Claubert inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each and 360 preferred shares of $100 each.> The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Fina?icial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 144-1970 Clc Elum River Nickel Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de janvier 1970, constituant en cor]>ora-lion: Gerald McCarthy, avocat, 4, Place Ville Marie, bureau 514, Montréal, Valerie Jean Higgins, 50, avenue Hudson, Mont-Royal, et Céline Trudeau, 2132, rue Bossuet, Montréal, ces deux dernières secrétaire, célibataires, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie minière, sous h' nom de « Cle Elum River Nickel Ltd.», avec un capital divisé en 5,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est 4, Place Ville Marie, bureau 514, Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 312-1970 Clc Elum River Nickel Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gerald McCarthy, advocate, 4 Place Ville Marie, Suite 514, Montreal, Valerie Jean Higgins, 50 Hudson Avenue, Mount Royal, and Céline Trudeau, 2132 Bossuet Street, Montreal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To carry on the business of a mining company, under the name of \"Cle Elum River Nickel Ltd.\", with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at 4 Place Ville Marie, Suite 514, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 312-1970 Clinique Médicale dc Rimouski inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de lu Loi «les compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Georges-H.Gagnon, 123, Côté, Maurice Turgeon, 450, Place Mgr Langis, Gérard Perron, 002, St-Gcrmain est, tous trois de Rimouski, et Lucien Gcndrcau, Luceville, tous «iiiatre médecins, pour les objets suivants: Administrer une ou plusieurs cliniques médicales et chirurgicales ou centres et bureaux médicaux ou chirurgicaux autres que des hôpitaux, sous le nom de « Clinique Méilicale «le Rimouski inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 125, boulevard René Lepage est, Rimouski, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 350-1970 Clini«|uc Médicale de Rimouski inc.Notice is given tliut under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges-H.Gagnon, 123 Côté, Maurice Turgeon, 450 Place Mgr Langis, Gérard Perron, 602 St-Gcrmain East, all three of Rimouski, and Lucien Gendreau, Luceville, all four physicians, for the following purposes: To direct one or several medical and surgical clinics or medical or surgical centres an«l offices other than hospitals, under the name of \"Clinique Médicale dc Rimouski inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at 125 René Lepage Boulevard East, Rimouski, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 350-1970 2418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Club Acadien Scpt-Iles Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du ' 9e jour «le février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Emile Lan teigne, coordon-nateur, 7, Leventoux, Gaétan Lavoie, entreposeur, 204, Papineau, Aurèle Beaulieu, assureur, 757, Dequen, Louise Giroux, secrétaire, fille majeure, 367, Évangéline, Claire Landry, ménagère, épouse d'André Gingras, 4, Vallée, Marie-Thérèse Poirier, ménagère, épouse «le Bertin Plourde, 915, Gallienne, Claude Gauthier, ajusteur mécanique, 999, Cartier, Régis Bourgeois, contremaître, canton Lctellier, Albert Bellivcau, 692, Évangéline, Laurent Bisson, 971, Brochu, tous deux commis, et André Simard, contremaître, 935, Giasson, tous «le Sept-Iles, pour les objets suivants: L'organisation des loisirs, sous le nom de « Club Acadien Sept-Iles ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de §2,000.Le siège social de la corporation est à Sept-Iles, district judiciaire de Hauterive.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-û 6304-1969 Club Acadien Sept-Iles Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 9th tiay of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Emile Lanteigne, co-ordi-nator, 7 Leventoux, Gaétan Lavoie, warehouseman, 204 Papineau, Aurèle Beaulicu, insurer, 757 Dequen, Louise Giroux, secretary, spinster of the full age of majority, 367 Évangéline, Claire Landry, housewife, wife of André Gingras, 4 ValliV, Marie-Thérèse Poirier, housewife, wife of Berlin Plourde, 915 Gallienne, Claude Gauthier, mechanical adjuster, 999 (.'artier, Régis Bourgeois, foreman, township of I^tellier, Albert Bellivcau, 692 Évangéline, Laurent Bisson, 971 Brochu, both clerks, and André Simard, forcmun, 935 Giasson, all of Scpt-Iles, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"Club Acadien Scpt-Iles\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $2,000.The head office of the corporation is at Sept -lies, judicial district of Hauterive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérât ires.34173 6304-19(19 Club Auto-Ncigc Lac Bouchettc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions : Ghislain Marcoux, garagiste, Benoît Gélinas, professeur, Jean-Marie Mungcr, chauffeur, Maurice Fortin, directeur de funérailles, Clermont Boulianne, opérateur, Gérard Gagné, entrepreneur, et Marcel Gaudreault, ouvrier, tous de Lac Bouchettc, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif et promouvoir en particulier les sports d'hiver, sous le nom de « Club Auto-Neige Lac Bouchette inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $25,000.Le siège social de \"la corporation est ù Lac Bouchette, district judiciaire de Roberval.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 578-1970-o Club Auto-Neige Lac Bouchettc inc.Notice is given that under Part III of Ihc Companies Act, letters patent, bearing date I lie 6th duy of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Ghislain Marcoux, garage-keeper, Benoît Gélinas, professor, Jean-Marie Munger, chauffeur, Maurice Fortin, funeral director, Clermont Bouliannc, operator, Gérard Gagné, contractor, und Marcel Gaudreault, labourer, all of Lac Uouchette, for the following purposes: To form and operate a sports club and In promote winter sports in particular, under the name of \"Club Auto-Neige Lac Bouchettc inc.\"'.The amount to which is limited the annual revenue of the immovable projierty which the corporation may acquire and jiossess, is $25,0011.The head office of the corporation is at Lac Bouchette, judicial district of Robcrval.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 578-1970 Club Auto-Neige St-Basilc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a acœrdé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: J.-Eudorc Caron, industriel, Leopold Mercure, marchand, André Julien, agent d'assurances, et Lucien Proulx, gérant des ventes, tous quatre de Saint-Basile, pour les objets suivants: Etablir et maintenir un centre d'activité sportive, sous le nom de « Club-Auto-Neige St-Basile inc.».Club Auto-Neige St-Basilc inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: J.-Eudore Caron.industrialist, Leopold Mercure, trader, André Julien, insurance agent, an«l Lucien Proulx, sale-manager, all four of Saint-Basile, for the following purposes: To establish and maintain a sports activity center, under the name of \"Club Auto-Neige St-Basile inc.\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder lu corporation, est de $40,000.Le siège social de la corporation est à Saint -Basile, district judiciaire dc Québec.sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 406-1970 Club dc hockey Chicoutimi inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour dc février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Baptiste Tremblay, homme d'affaires, chemin Sydenham, Marcel Claveau, notaire, 1097, rue Jacques-Cartier est, et Roger Page, avocat, 367, Marie-Rollet, tous trois de Chicoutimi, pour les objets suivants: Former et exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport du hockey, sous le nom de « Club de hockey Chicoutimi inc.».I/c montant uuquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $10,000.Le siège social de la corporation est ii Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 166-1970 Club de Golfdc Plessisville liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Julius Max Sclingcr, vendeur, Edith Balacan, secrétaire, épouse dudit Julius Max Sclingcr, Stanley Lyon Sclingcr, avocat, tous trois de («265, Mountain Sights, Claire Wilisky, secrétaire, fille majeure, 3420, Hutchison, tous quatre de Montréal, et J.-Paul Robert, avocat, 1660, Place d'Anjou, Saint-Bruno-de-Montarvillc, pour les objets suivants: Exploiter un club de golf, un pavillon (club house) et parcours dc pratique (driving range), sous le nom de « Club dc Golf de Plessisville ltée », avec un capital total dc $50,000, divisé i'ii 10 actions ordinaires de $100 chacune et en 10 actions privilégiées dc $4,900 chacune.Le siège social dc la compugnie est à Plessisville, district judiciaire de Mégantic.I.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.14173-0 5846-1969 Club dc tir de Saint-Tite inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ¦le la troisième partie de lu Loi des compagnies, 11 a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de février 1970, constituant en corjwration sans capital-actions: Raymond Béland, bijoutier, 251, Notre-Dame, André Desaulniers, entrepreneur-électricien, 113, Saint-Paul, et Raymond Gauthier, ébéniste, route 19-B, tous trois de Saint-Titre, pour les objets suivants: Exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport du tir à l'arc, du tir à la 2419 The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $40,000.The head office of the corporation is at Saint-Basile, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 406-1970 Club de hockey Chicoutimi inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, liave been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jean-Baptiste Tremblay, businessman, Sydenham Road, Marcel Claveau, notary, 1097 Jacques-Cartier Street East, and Roger Page, advocate, 367 Marie-Rollet, all three of Chicoutimi, for the following purposes: To form and operate a sports club and to promote hockey in particular, under the name of \"Club de hockey Chicoutimi inc.\".The amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $10,000.The head office of the corporation is at Chicoutimi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 166-1970 Club ¦'(¦ Golf de Plessisville ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives, incorporating: Julius Max Sclingcr, salesman, Edith Balacan, secretary, wife of said Julius Max Sclinger, Stanley Lyon Selinger, advocate, all three of 6265 Mountain Sights, Claire Wilisky, secretary, spinster of the full age of majority, 3420 Hutchison, all four of Montreal, and J.-Paul Robert advocate, 1660 Place d'Anjou, Saint-Bruno-de-Montarvillc, for the following purposes: To operate a golf club, a club house and a driving range, under the name of \"Club de Golf de Plessisville ltée\", with a total capital stock of $50,000, divided into 10 common shares of 8100 each and into 10 preferred shnres of $4,900 each.The head office of the company is at Plessisville, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5S46-1969 Club de tir de Saint-Tite inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Raymond Béland, jeweller, 251 Notre-Dame, André Desaulniers, electrical contractor, 113 Saint-Paul, and Raymond Gauthier, cabinet maker, route 19-B, all three of Saint-Tite, for the following purposes: To operate a sports club, and, in particular, to promote the sport of archery, and shooting 2420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102- année, n° 17 carabine, fusil, pistolet et revolver, sous le nom oration, est de $5,000.Le siège social dc la corporation est ù Saint-Tite, district judiciaire de Saint-Maurice.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 461-1970 Club Kiwanis de Druniniondville inc.Kl» an is Club of Drummondville Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Roméo Clément, publicitaire, 291, Brock, Jean Valade, courtier en assurance, 335, rue Laurier, Pierre-Paul Pion, 116, Notre-Dame, Claude Lemire, 178, boulevard Des Ormes, Clément Riendeau, 970, 113e avenue, Guy Bolduc, 271, rue Garceau, Jean-Claude Tcssier, 484c, rue Brock, tous cinq gérants, André Jean, notaire, 424, rue Dumoulin, Ronaldo Houle, 570, rue Dumoulin, Hugues Savoie, 331, rue Mélançon, tous deux commerçants, Aurélicn Sylvestre, agent, 1178.rue Dionne, tous onze dc Drummondville, Koucrt Plamondon, commerçant, 2015, Fr.idet, et Gérard Raymond, agent, 590,105e avenue, ces deux dernirs de Drummond-ville-Sud, pour les objets suivants: Donner la primauté aux valeurs humaines et sprirituelles de préférence aux valeurs matérielles de la vie, sous le nom de « Club Kiwanis dc Drummondville inc.\u2014 Kiwanis Club of Drummondville Inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc $20,000.Le siège social de la corporation est à Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 482-1970 Club moto-neige Neuville inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Michel Turgeon, fonctionnaire; 601, des Érables, Omcr Côté, livreur, 531, des Érables, et Raymond Côté, camionneur, 456, route Nationale, tous trois dc Neuville, pour les objets suivants: Favoriser la pratique du sport de l'autos-neigc et le développement social des membres, sous le nom de « Club moto-neige Neuville inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $15,000.Le siège social de la corporation est a Neuville, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-q 514-1970 with rifles, guns, pistols and revolvers, under the name of \"Club de tir de Saint-Tite inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $5,000.The head office of the corporation is at Saint-Tite, judicial district of Saint-Maurice.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial hislitutions, Companies and Cooperatives.34173 461-1970 Club Kiwanis de Drummondville inc.Kiwanis Club of Drummondville Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 27th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Roméo Clémcnl.publicist, 291 Brock, Jean Valnde, insurance-broker, 335 Laurier Street, Pierre-Paul Pion, 116 Notre-Dame, Claude Lemire, 178 Des Ormes Boulevard, Clément Riendeau, 970, 113th Avenue, Guy Bolduc, 271 Garceau Strcel.Jean-Claude Tcssier, 4S4c Brock Street, all five managers, André Jean, notary, 424 Dumoulin Street, Ronaldo Houle, 570 Dumoulin Strcel, Hugues Savoie, 331 Mélançon, Street both traders, Aurélien Sylvestre, agent, 1178 Dionne Street, all eleven of Drummondville, Robert Plamondon, trader, 2015 Fradct, ami Gérard Raymond, agent, 590, 105th Avenue, the latter two of Drummondville South, for the following purposes: To give priority to human and spiritual values in preference to the material values of life, under the name of \"Club Kiwanis de Drummondville inc.\u2014 Kiwanis Club of Drummondville Inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $20,000.The head office of the corporation is at Drum mondville, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 482-197(1 Club moto-neige Neuville inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Michel Turgeon, civil servant, 601 des Érables, Orner Côté, delivery-man, 531 des Érables, and Raymond Côté, trucker, 456 National Highway, all three of Neuville, for the following purposes: To promote the practice of snow-mobiling as u sport and the social development of its members, under the name of \"Club moto-neige Neuville inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $15,000.The head office of the corporation is at Neuville, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 514-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April SB, 1970, Vol.10S, No.17 2421 Club sportif universel inc.Universal Sporting Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé d'es lettres patentes, en date du 13c jour de février 1970, constituant en corporation: Ghislain Bouchard, 470 est, 50e rue, Char-leshourg, Marc de Goumois, 86, rue Saint-Louis, tous deux avocats, et Rose Parent, secrétaire, veuve d'Edgar Parent, 1120, chemin Sainte-Poy, ces deux derniers de Québec, pour les objets suivants: Établir, maintenir et diriger un club sportif, sous le nom de « Club sportif universel inc.\u2014 Universal Sporting Club Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 86, rue Saint-Louis, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-minis! rc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 410-1970 Conipclcc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jean-Marc Pouliot, Michel Bégin, tous deux imprimeurs, et Roland Collette, maquettiste, tous trois dc Lac Etchemin, pour les objets suivants : Faire affaires comme imprimeurs, éditeurs, papetiers, lithographes, graveurs, relieurs, libraires, fondeurs typographes, compositeurs à froid, compositeurs photo-électronique et autres commerces connexes, sous le nom de « Compelec inc.», avec un capital total dc $100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 810, avenue Belvédère, Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 6336-1969 Club sportif universel inc.Universal Sporting Club Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ghislain Bouchard, 470, 50th Street East, Charlesbourg, Marc de Goumois, 86 St-Louis Street, both lawyers, and Rose Parent, secretary, widow of Edgar Parent, 1120 Ste-Foy Road, the latter two of Québec, for the following purposes: To establish, maintain and conduct an athletic club, under the name of \"Club sportif universel inc.\u2014 Universal Sporting Club Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 86 St-Louis Street, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 410-1970 Compclcc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd clay of January, 1970, have been issued by tlic Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Marc Pouliot, Michel Begin, both printers, and Roland Collette, Iayoutman, all three of Lac Etchemin, for the following purposes: To carry on business as printers, publishers, stationers, lithographers, engravers, bookbinders, booksellers, type-founders, type-setters, photo-electronic setters and other businesses connected therewith, under the name of \"Compelec inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of $100 each.The head office of the company is at 810 Belvédère Avenue, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6336-1969 l.c comptoir familial dc la region de l'Amiante inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ¦ le la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour dc février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Alcide Pelchat, agent de sécurité sociale, 785, Sylvain, Jacques Croteau, travailleur social, 348, 8e rue ouest, et Jean Doyon, entrepreneur général, 471, 4c rue ouest, tous trois dc Thetford Mines, pour les objets suivants: Établir et exploiter un organisme dans le but de recueillir, distribuer aux assistés sociaux ou autres personnes dans le besoin, des vêtements et autres choses nécessaires à la vie, sous le nom de « Le comptoir familial dc la région de l'Amiante inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels provenant des biens immobiliers de la corporation est de $50,000.Le comptoir familial dc la région dc l'Amiante inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Alcidc Pelchat, social security agent, 785 Sylvain, Jacques Croteau, social worker, 348, 8th St.West, and Jean Doyon, general contractor, 471, 4th St.West, all three of Thetford Mines, for the following purposes: To establish and operate an organization to welcome and to distribute among those on social assistance or others in need, clothing and other necessities of life, under the name of \"Le comptoir familial de la région dc l'Amiante inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000. 2422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Le siège social «le la corporation est à Thct-ford Mines, district judiciaire de Mégantic.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 552-1970 Concord Sportswear Ltd.Les vêtements sports Concorde ltée Lc_ ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accortlé des lettres patentes, en date du 12c jour «le janvier 1970, constituant en corporation: Bernard Gillman, agent manufacturier, 1320, Allan!.Sainte-Foy, Raymond Blanchettc, vendeur, et Jacques-Gilles Savoie, manufacturier, ces deux derniers de Manseau, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce d'accessoires vestimentaires et accessoires dc toutes sortes, sous le nom de « Concord Sportswear Ltd.\u2014 Les vêtements sports Concor«le ltée», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et 2,(M)0 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 1320, Allard, Sainte-Foy, district judiciaire «le Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 6141-1969 Construction Solcr incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, «m'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes, en date du 13e jour de février 1970, constituant en corporation : Claude Quirion, notaire, 2030, Père Lelièvre, Duberger, Marguerite Lagueux, réceptionniste, SO, Lockwcll, et Michèle Roy, secrétaire, 384, I/Ockwell, ces deux dernières filles majeures, de Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de constructions, sous le nom de « Construction Sotcr incorporée », avec un capital total dc $100,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune et en 600 actions privilégiées «le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire «le Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 709-1970 Les Consultants FMB inc.FMB Consultants Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a ac«»rdé des lettres patentes, en date du lie jour «le février 1970, constituant en corporation : Raymond Lessard, Valcartier-Village, Maurice Jacques, 1115, Vimont, Sillery, Jean Blanchet, 520, avenue Laurier, et Claude Blanchard, 1187, St-Cyrille ouest, ces deux derniers «le Québec, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme consultants ou agents pour toute entreprise commerciale, sous le nom de « Les Consultants FMB inc.\u2014 FMB Consultants Inc.\", avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires dc $1 chacune et en 3,500 actions privilégiées dc $10 chacune.The head office of the corporation is al Thel-ford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 552-1970 Concord Sportswear Ltd.Les vêtements sports Concorde ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, incorporating: Bernard Gill-man, manufacturer's agent, 1320 Allard, Saintc-Foy, Raymond Blanchettc, salesman, and Jacques-Gilles Savoie, manufacturer, the latter Iwo of Manseau, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel and accessories of all kinds, under the name of \"Concord Sportswear Ltd.\u2014 Les vêtemcnls sports Concorde ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each an«l 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1320 Allard, Sainte-Foy, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-u 6141-19li!l Construction Sotcr incorporée Notice is given lliat under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Quirinn, notary, 2030 Père Lelièvre, Duberger, Marguerite Lagucux, receptionist, 80 Lockwcll, an«l Michèle Roy, secretary, 384 Lockwell, the latter two spinsters of the full age of majority, of Québec, for the following purposes: To carry on business as a construction company, under the name of \"Construction Soler incorporée\", with a total capital stock of $100,000.divided into 400 common shares of $100 each and into 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 709-1970 Les Consultants FMB inc.FMB Consultants Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing (late the 11th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Lessard, Valcartier-Village, Maurice Jacques, 1115 Vimont, Sillery, Jean Blanchet, 520 Laurier Avenue, and Claude Blanchard, 1187 St-Cyrille West, the latter two of Québec, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as consultants or agents for any commercial enterprise, under the name of \"Les Consultants FMB inc.\u2014 FMB Consultants Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 5,000 common sluircs of $1 each and into 3,500 preferred shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2423 Le siège social de la compagnie est 872, Le Fremont, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 727-1970 Le Cornet Blanc (Miron) incorporée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation: (lilies Miron, commerçant, Monique Coupai, ménagère, épouse dudit Gilles Miron, tous deux de 5610, Jules-Auclair, Montréal-Nord, et Lucille Miron, secrétaire, fille majeure, 263, rue Laro-cliellc, Repentigny, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Le Cornet Blanc (Miron) incorporée », avec un capital total de $40,000, divisé en \u20221,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 5610, Jules-Auclair, Montréal-Nord, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 5997-1969 The head office of the company is at 872 Le Prémont, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 727-1970 Lc Cornet Blanc (Miron) incorporée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Miron, trader, Monique Coupai, housewife, wife of said Gilles Miron, both of 5610 Jules-Auclair, Montreal North, and Lucille Miron, secretary, spinster of the full age of majority, 263 Larochelle Street, Repentigny, for the following purposes: To operate a dairy in all its specialties, under the name of \"Le Cornet Blanc (Miron) incorporée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 5610 Jules-Auclair, Montreal-North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5997-1969 Rcnald Cyr inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de janvier 1970, constituant en corporation: (!uy Perreault, notaire, 198, Maple-Grove, Bruno l.abcrge, assistant-comptable, 940, Des Cèdres, tous deux dc Maple Grove, et Roger Giroux, comptable, 549, Salaberry, Bcauharnois, pour les objets suivants: Faire affaires comme fabricants de liqueurs douces et en faire l'embouteillage et la vente, sous lc nom de « Renald Cyr inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Melochc-ville, district judiciaire dc Bcauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 356-1970 Renald Cyr inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Perreault, notary, 198 Maple-Grove, Bruno Laberge, assistant accountant, 490 Des Cèdres, both of Maple Grove, and Roger Giroux, accountant, 549 Salaberry, Bcauharnois, for the following purposes: To carry on business as soft drink manufacturers and carry out their bottling and sale, under the name of \"Renald Cyr inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided inot 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Mclochc-ville, judicial district of Beauharnois.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 356-1970 Dafomax inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Jean Clavcl, conseiller en relations publiques, 1980, boulevard Graham, Hugues Ferron, 17, Lazard, Gilles-G.Tessicr, 445, Grenfell, tous deux avocats, tous trois de Mont-Royal, et Jeannette Fournier, secrétaire, fille majeure, 3455, Redpath, Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des restaurants, sous lc nom dc « Dafomax inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,800 actions privilégiées dc $10 chacune.Dafomax inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Clavel, public relations consultant, 1980 Graham Blvd., Hugues Ferron, 17 Lazard, Gilles-G.Tcssier, 445 Grenfell, both advocates, all three of Mount Royal, and Jeannette Fournier, secretary, spinster of the full age of majority, 3455 Redpath, Montreal, for the following purposes: To operate restaurants, under the name of \"Dafomax inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $1 each and 3,800 preferred shares of $10 each. 2424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 264-1970 Diversified Communications Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Guy-E.Boisvert, 4976, Glencairn, Montréal, G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505 Moorc, Laval, tous trois avocats, Denyse Marcoux, 1488, Galt, Montréal, et Louise Delorme, 350, avenue des Pins, Saint-Lambert, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Exploiter un commerce dc réclame et dc publicité, sous lc nom de « Diversified Communications Limited », avec un capital-actions divisé en 2,500,000 actions sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 369-1970 Les dix associés inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de février 1970, constituant en corporation : Jeanninc Lajoie, femme d'affaires, veuve de .T.-Aimé Masson, 22, Jacques-Cartier est, Philippe Tremblay, 1071, Boily, tous deux dc Chicoutimi, et Maurice Bilodeau, 188, St-Nicholas, Chicouti-mi-Nord, ces deux derniers représentants de vente, pour les objets suivants: Faire affaires comme prêteurs d'argent, sous lc nom de « Les dix associés inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 600 actions ordinaires de $50 chacune et en 200 actions privilégiées dc $50 chacune.Le siège social de la compagnie est à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-o 195-1970 Dubord composition inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: Marcel Dubord, technicien, Nicole Émond, ménagère, épouse dudit Marcel Dubord, tous deux de 78, 6e avenue, et Lucien Dubord, entrepreneur en construction, 275, Notrc-Damc-dc-Fatima, tous trois de Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme imprimeurs, sous le nom de « Dubord composition inc.», avec un capital total de $20,000, divisé en 200 actions ordinaires de $10 chacune et en 180 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o \u2022 214-1970 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 264-1970 Diversified Communications Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy-E.Boisvert, 4976 Glencairn, Montreal, 6.Harold Pickcl, 47 Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, all three advocates.Denyse Marcoux, 1488 Gait, Montreal, ami Louise Delorme, 350 Pine Avenue, Saint-Lambert, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on an advertising and publicity business, under the name of \"Diversified Communications Limited\", with a capital stock divided into 2,500,000 shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 369-197(1 Les dix associes inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jcanninc Lajoie, businesswoman, widow of J.-Aimé Masson, 22 Jucqucs-Cartier cast, Philippe Tremblay, 1071 Boilv, both of Chicoutimi, and Maurice Bilodeau, 188 St-Nicholas, Chicoutimi-North, the latter two sales representatives, for the following purposes: To carry on business as money lenders, under the name of \"Les dix associés inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 600 common shares of $50 each and 200 preferred shares of $50 each.The head office of the company is at Chicouli-mi, judicial district of Chicoutimi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 195-197(1 Dubord composition inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th érativcs donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Paul-Emile Lemay, 26, Des Saules, Saint-Masile-Ic-Grand, Yves Lemay, tous deux modeleurs, et Ghislaine Lnnglois, ménagère, épouse dudit Yves Lemay, ces deux derniers de 8736, rue Clark, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc moules en bois, en plastiques ou en métal dc toutes sortes et des articles faits totalement ou en partie de ces substances ou autres semblables, sous le nom de « Elite Patterns Works Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 11665, rue Lctcllicr, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Mouchard.34173-o 314-1970 1a-s Entreprises Bonncau Teasdale liée llim m ran Teasdale Enterprises Ltd.Iornting: Jean-René Mouette, mechanic, 184 Harold, Roland Lavictoirc, electrician, 131 Elizabeth, and Normand Racicot, clerk, 286 East, all three of Gatineau, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Entreprises La Ronde inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and into 3,500 preferred shares of $10 each.The heud office of the company is at Gatineau, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 19-1970 Entreprises Les Signes du Zodiaque inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of November, 1969, have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Darlcne T.Segal, 7925 Kingsley, Suzanne Yanow, 4921 Glcncairn, and Sonya Bclivcau, 1280 St-Marc, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, of Montreal, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Entreprises Les Signes du Zodiaque inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 254 Ste-Catherine Street East, suite 3, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5404-1969 Entreprises Mcico inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions^ Companies and Cooperatives, incor|>orating: Edouard Linares, 42 Regent, Antonio Gonzalez, 174 Regent, both engineers, of Greenfield Park, and Lan- 2428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n\" 17 Park, et Lauréandc Bergeron, ménagère, épouse de Denis St-Laurcnt, 2007, Brébcuf, Longueuil, |x>ur les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de machines à sons dc tous genres, sous lc nom de < Entreprises Meico inc.», avec un capital total dc $100,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc S10 chacune et en 800 actions privilégiées dc S100 chacune.!.ortcfcuillc (holding) et dc placement, sous le nom de « Epcoli Inc.», avec un capital total dc 8601,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc 81 chacune et en 600 actions privilégiées dc 81,000 chacune.Lc siège social de la compagnie est 345, rue Wellington sud, Sherbrooke, district judiciaire dc Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piu lippe Bouchard.34173-0 5888-1969 Exccllo Imports Co.Ltd.I.c ministre des institutions financières, coni|>a-gnics et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Donald M.Devine, 3300, de Falaise, Montréal, Charles E.Flam, 5782, avenue Trinity, et Enrl S.Cohen, 5475, Rosedalc, app.304, ces deux derniers dc Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire lc commerce de produits, articles et marchandises dc toutes sortes, sous le nom dc « Excello Imports Co.Ltd.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «le $10 chacune et 3,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 800, Place Victoria, bureau 612, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 266-1970 Everest Construction Inc.I a- ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu delà première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c réandc Bergeron, housewife, wife of Denis Sl-Laurcnt, 2007 Brébeuf, Longueuil, for the following purposes: To manufacture and deal in sound machines of all kinds, under the name of \"Entreprises Meico inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 800 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Sainl-Lambcrt, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 321-1970 Epcoli Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of December, 1969 have been issued by the Lieutenant-Governor of the Province, incorporating: Gilles Coulombe, advocate, Rural Route number 1, Lennox ville, Françoise Fouquct, spinster of the full age of majority, 1011 McManamy Boulevard, and Carole St-Roch, wife of Jean-Guy St-Roch, 1060 Federal Street the latter two secretaries of Sherbrooke, for the following purposes: To deal in all products, articles ami goods and to carry on business as n real estate, construction, management.holding and investment company, under the name of \"Epcoli Inc.\", with a total capital stock of $601,000, divided into 1,000 common shares of 81 each and 600 preferred shares of $1,000 each.The head office of the company is at 345 Wellington Street South, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5888-19(i'.i Exccllo Imports Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Donald M.Devine, 3300 de Falaise, Montreal, Charles E.Flam, 5782 Trinity Avenue, and Earl S.Cohen.5475 Roscdale, Apt.304, the latter two of Cole Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To deal in goods, wares ami merchandise of all kinds, under the name of \"Excello Imports Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 800 Plucc Victoria, Suite 612, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 266-1970 Everest Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2429 jour dc Janvier 1970, constituant en corporation : Daniel Kingstonc, 4985, Iona, Joseph Silver, 74G1, Kingslcy, tous deux de Montreal, Irving L.Adessky, 56, Heath Place, Hampstead, et Diony-sia Zcrbisias, fille majeure, 5525, Westbourne, Côte Saint-Luc, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Everest Construction Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires île 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe bouchard.34173 263-1970 F.L.Sales Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Irving L.Adcssky, 56, Heath Place, Hampstead, (lilies Poulin, 103, Ashton, Saint-Laurent, et Joseph Silvcrt, 7461, Kingsley, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: L'industrie et lc commerce dc bottes, chaussures, articles et accessoires dc cuir, sous lc nom dc « F.L.Sales Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune Ix: siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 183-1970 panics and Cooperatives, incorporating: Daniel Kingstone, 4985 Iona, Joseph Silver, 7461 Kingsley, both of Montreal, Irving L.Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, and Dionysia Zcrbisias, fille majeure, 5525 Westbourne, Côte Saint-Luc, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Everest Construction Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2,000 preferred shurcs of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 263-1970 F.L.Sales Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dote the 15th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving L.Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, Gilles Poulin, 103 Ashton, Saint-Laurent, and Joseph Silvcrt, 7461 Kingsley, Côte Saint-Luc, all three udvocatcs, for the following purposes: To manufacture and deal in boots and shoes, leather goods and accessories, under the name of \"F.L.Sales Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 1S3-1970 Fashion First Manufacturing (1969) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Abraham Shustcr, 5710, Wolselcy, Lawrence (ilazer, 7920, Kingsley, tous deux dc Côte Saint-l.uc, et Arthur Marcovitch, 1540, Summerhill, Montréal, tous trois avocats, ixmr les objets suivants: L'industrie et le commerce du vêtement et d'accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom de * Fashion First Manufacturing (1969) Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc $10 chacune, 2,500 actions privilégiées, classe * A » d'une valeur au pair de $10 chacune et 5,000 actions privilégiées, classe « B », d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 420-1970 Fashion First Manufacturing (1969) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Abraham Shus-ter, 5710 Wolseley, Lawrence Glazer, 7920 Kings-ley, both of Côte Saint-Luc, and Arthur Marcovitch, 1540 Summerhill, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and wearing apparel of all kinds, under the name of \"Fashion First Manufacturing (1969) Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of the par value of $10 each, 2,500 class \"A\" preferred shares of the par value of $10 each and 5,000 class \"B\" preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-d 420-1970 2430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n° 17 Fédération Québécoise des Sociétés d'Aviron inc.Québec Federation of Rowing Societies Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour dc février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Raoul Lebailly, administrateur, 478, rue Laval, François Godbout, avocat, 1274, Ktliicr, tous deux de Laval, et Harry Goctsclii, agent de réclamations, 2555, Benny, app.805, Montréal, pour les objets suivants: Favoriser lc sport dc l'aviron, sous lc nom de « Fédération Québécoise des Sociétés d'Aviron inc.\u2014 Québec Federation of Rowing Societies Inc.».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut détenir ou posséder est de $4,000,000.Lc siège social dc la corporation est à Laval, district judiciaire dc Montréal.Ia sous-ministre des institulionsfinancières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 08-1970 Fédération Québécoise des Sociétés d'Aviron inc.Québec Federation of Rowing Societies Inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Raoul Lebailly, administrator, 478 Laval Street, François Godbout, advocate, 1274 Éthicr, both of Laval, and Hurry Goctschi, claims agent, 2555 Benny, Apt.805.Montreal, for the following purposes: To promote rowing, under the name of \"Fédération Québécoise des Sociétés d'Aviron inc.Québec Federation of Rowing Societies Inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $4,000,000.The head office of the corporation is at Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 08-197(1 First Edition Fashions Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19c jour dc janvier 1970, constituant en corporation : Priscilla Wright, administrateur, 5550, rue Ful-lum, Sandra Shcinfcld, sténographe, 6742, rue de Vimy, toutes deux célibataires, et Michael Greenblatt, avocat, 1745, avenue Cedar, tous trois de Montréal, pom les objets suivants: L'industrie et le commerce de vêtements sports pour femmes et enfants et autres accessoires vestimentaires, sous lc nom dc « First Edition Fashions Ltd.', avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173 1-1970 First Edition Fashions Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Priscilla \\\\ right.-executive, 5550 Fullum Street, Sandra Shcinfcld.stenographer, ,6742 de Vimy Street, both spinsters, and Michael Greenblatt, advocate, 1745 Cedar Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ladies and children's sportswear and other apparel, under the name of \"First Edition Fashions Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,0(10 common shares having a par value of $10each and 3,000 preferred shares having a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ia-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 1-1970 Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gilles Filion, avocat, 11645, rue Guertin, Isabelle Lemay, secrétaire, fille majeure, 10560, Clark, tous deux dc Montréal, et Gustave Monctte, avocat, 7, chemin Ste-Catherine, app.605, Outremont, pour les objets suivants: Venir en aide à l'hôpital dc Sacré-Coeur, sous le nom dc « Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc $500,000.Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur dc Montréal Notice is given that under Fart HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Gilles Filion, advocute.11645 Guertin Street, Isabelle Lemay, secretary, spinster of the full age of majority, 10560 (\"lark, both of Montreal, and Gustave Monette, advocate, 7 Ste-Catherine Road, Apt.605, Outre-mont, for the following purposes: To give assistance to the Sacred Heart Hospital, under the name of \"Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is of $500,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 2b, 1970, Vol.102, No.17 2431 Lc siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire dc Montréal, /.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 5520-1969 The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5520-1969 Fondation Gertrude Boycr Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du -le jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gertrude Cousineau, ménagère, veuve de Ludger Boyer, 832, boulevard Ste-Croix, Saint-Laurent, Jean Provost, comptable agréé, 725, avenue Davaar, et Maurice Martel, avocat, 1301, St-Viateur ouest, ces deux derniers d'Outremont, pour les objets suivants: Promouvoir et administrer une organisation de charité pour les fins suivantes: lc soulagement île la pauvreté, l'avancement de la religion, l'avancement dc l'éducation, ou l'avancement d'autres buts dont la communauté bénéficiera, sous lc nom de « Fondation Gertrude Boyer ».Lc montant auquel sont limités les revenus annuels provenant des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de §1,000.000.Lc siège social dc la corporation est 832, boulevard Ste-Croix, Saint-Ixiurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.31173-0 392-1970 Fondation Gertrude Boyer Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies nnd Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Gertrude Cousineau, housewife, widow of Ludger Boycr, 832 Ste-Croix Blvd., Saint-Laurent, Jean Provost, chartered accountant, 725 Davaar Ave., and Maurice Martel, advocate, 1301 St-Viateur west, the latter two of Outrcmont, for the following purposes: To promote and administer a charitable organization for the following purposes: the succouring of the poor, the advancement of religion, education or other goals which would benefit the community, under the name of \"Fondation Gertrude Boycr\".The amount to which the annual income from the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $1,000,000.The head office of the corporation is at 832 Ste-Croix, Blvd., Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 392-1970 Fondcco inc.\\x ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Gilles L'Écuyer, avocat, 2580, Sillcry-Plaza, »M3, Sillery, Gilles Gagnon, représentant de ventes, et Marc Gagnon, actuaire, ces deux derniers dc 837, avenue Uochette, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement, \u2022 le portefeuille (holding), de gestion et dc finance, sous le nom «le « Fondeco Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 327-1970 Fondeco inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles L'Écuyer, advocate, 2580 Sillcry-Plaza, #M3, Sillery, Gilles Gagnon, sales representative, and Marc Gagnon, actuary, the latter two of 837 Rochette Avenue, St.Foy, for the following purposes: To carry on business as an investment, holding, management and finance company, under the name of \"Fondeco inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each ami into 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 327-1970 Foyer Dorval Ia.' ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Mariette Labrosse, Cécile Cou-lombe et Georgette Boutin, toutes trois religieuses, dc 3165, Place dc Ramezay, Montréal, pour les objets suivants: Foyer Dorval Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th (lay of February, 1970, have lieen issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Mariette Labrosse, Cécile Coulombc and Georgette Boutin, all three nuns, of 3165 Place de Ramezay, Montreal, for the following purposes: 2432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' aimée, n° 17 Fournir à des couples ûgés et ù des personnes Agées des deux sexes, un foyer leur permettant de vivre en toute sécurité, sous le nom de « Foyer Dorvol ».Ix: montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $2,000,000.LfC siège social dc la corporation est à Dorval, district judiciaire de Montréal.Ij\u20ac soii.i-miiii.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-1'llILlPPE BoUCHAHD.34173-0 104-1970 Frcsal Holdings Inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: John George Gibson, administrateur immobilier 100 sud, avenue Brock, Montréal-Ouest, Gordon Leonard McGilton, avocat et procureur, 636, avenue Belmont, Westmount, et Miriam Berstein, secrétaire, épouse de David Barash, 1755, avenue North, Outremont, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie dc portefeuille, sous lc nom dc < Frcsal Holdings Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune, 2,800 actions privilégiées, classe « A», d'une valeur au pair de $10 chacune et 1,100 actions privilégiées, classe « B », d'une valeur au pair «le $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIPPE Boi'chahd.34173 1338-1969 G.L.K.inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie dc la Loi des compagnies, il u accorde des lettres patentes, en date du 6e jour de février 1970, constituant en corporation : Jean Lortie, 1868, Bergemont, Québec, Marcel Racine, 2070, «lu Monument, Giffurd, tous deux entrepreneurs, et Roland Gagnon, surintendant, Saint-Félix-il'Otis, pour les objets suivants: Faire nffaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et fabriquer et faire le commerce «le moteurs, et accessoires électriques de toutes sortes, sous lc nom de « G.I.H.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 800 actions ordinaires «le $50 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Québec, district judiciaire dc Québec.Ijô sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Fhtuppe Bouchard.34173-0 576-1970 Galerie d'art Langelier inc.Le ministre, «les institutions financières, compagnies et eoopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Claude-H.Gohicr, homme d'affaires, Nicole Paquet, ménagère, épouse dudit Claude-H.Gohicr, tous deux dc 12457, Bergerac, Pierre-fonds, et Paul Viens, artiste-peintre, 1670, Biset, Laval, pour les objets suivants: To give aged couples and aged individuals of both sexes a home permitting them to live in safety, under the name of \"Foyer Dorval\".The anion i ! I to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $2,000,000.The head office of the corporation is at Dorval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, ¦ Companies and Cooperatives.34l73-o 164-1070 Frcsal Holdings Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John George Gibson, estate administrator, 100 Brock Avenue South, Montreal West, Gordon Leonard McGilton, burrister and solicitor, 636 Belmont Avenue, Westmount, and Miriam Berstein, secretary, wife of David Barash, 1755 North Avenue, Outremont, for the following purposes: To carry on the business of a holding company, under the name of \"Frcsal Holdings Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares at the par value of $1 each, 2,800 class \"A\" preferred shares at the par value of $10 each and 1,100 class \"B\" preferred shares at the par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 34173-o 3138-1000 G.L.R.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, beuring date the 6th day of February, 1970.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jeun Lortie, 1868 Bergcmont, Québec, Marcel Racine.2070 du Monument, Giffard, both contractors, und Roland Gugnon, superintendent, Saint-Félix-d'Otis, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to manufacture and deal in motors and electrical applicances of all kinds, under the name of \"G.L.R.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into SOU common shares of $50 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 576-1970 Galerie d'art Langelier inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies an«l Cooperatives, incorporating: Claude-H.Goliier, businessman, Nicole Paquet, housewife, wife of the said Claude-H.Gohicr, both of 12457 Bergerac, Picrrefonds, and Paul Viens, artist-painter, 1670 Bizet, Laval, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2433 Poire lc commerce de peintures, sculptures, miIUu11aI et tout autre objet d'art, sous le nom de «Galerie d'art Langelier inc.», avec un capital total dc 8-111,001), divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Saint-Léonard, district judiciaire dc Montréal, /.c tout-minière des institutions financières, ' compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 401-1970 Gatineau oxygène inc.Ix! ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île In première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de février 1970, constituant en corporation: Joseph-Roland Lévesquc, homme d'affaires, Mabel Edna Sinclair, maltresse dc maison, épouse dudit Joseph-Roland Lévesquc, tous deux de 241, avenue Principale, Tourainc, et Maric-l'aulc Laviolettc, secrétaire, fille majeure, 8, rue Charlevoix, Hull, pour les objets suivants: Faire le commerce des gaz de toutes sortes et de tous autres produits servant ù la soudure, au chauffage et autres besoins industriels et domestiques, sous lc nom dc < Gutincau oxygène inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 500 actions ordinaires dc $10 chacune et en 3,500 actions privilégiées dc $10 chacune.Lcsiège social dc la compagnie est à Touruine, district judiciaire dc Hull, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippk Bouciiahd.34173-0 5132-1909 To deal in paintings, sculptures, handicrafts and all other objects of art, under the name of \"Galerie d'art Langelier inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Saint-Léonard, judicial district of Montreal.Ls-Phii.ippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 401-1970 Gatineau oxygène inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|)cratives, incorporating: Joseph-Roland Lévesquc, businessman, Mabel Edna Sinclair, housewife, wife of the said Joseph-Roland Lévesquc, both of 241 Main Street, Tourainc, and Marie-Paule Laviolctte, secretary, spinster of the fulll age of majority, 8 Charlevoix Street, Hull, for the following purposes: To carry on business dealing in gas of all kinds and in all other products used in welding, heating and other industrial and domestic needs, under the name of \"Gatineau oxygène inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of $10 each and 3,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Touraine, judicial district of Hull.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutioîis, Companies and Cooperatives.34173 5132-1969 Gestion Gaétan Laurence ltée lx: ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres pu ten tes, en date du 14e jour de janvier 1970, constituant en corporation: ii ad an Laurence, constructeur, Jeanne Per-reuult, ménagère, épouse dudit Gaétan Laurence, tous deux de 69, Sauriol, et Jean Guévremont.entrepreneur, 2230, Concorde, tous trois dc Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « Gestion Gaétan Laurence ltée», avec un capital total de $40,000, divisé en 5 actions ordinaires dc \u2022S100 chacune, 3,947 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 30 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Ix; siège social de la compagnie est 69, Snuriol, Laval, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.:i4173-o 65-1970 Gestion Gaétan Laurence ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gaétan Laurence, builder, Jeanne Perreault, housewife, wife of the said Gaétan Laurence, both of 69 Sauriol, and Jean Guévremont, contractor, 2230 Concorde, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Gestion Guétan Laurence ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 5 common shares of $100 each, 3,947 preferred class \"A\" shares of $10 each and 30 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at 69 Sauriol, Lu val, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 65-1970 Gestion Real Laurence ltée lx; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Réal Laurence, constructeur, Raymonde Perreault, ménagère, épouse dudit Réal Laurence, tous deux de 4371, Gatineau, Laval, et Maurice Gestion Réal Laurence ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Real Laurence, builder, Raymonde Perreault, housewife, wife of said Real Laurence, both of 4371 Gatineau Laval, and Maurice Martel, advocate, 1301 2434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2B avril 1970, 102' aimée, n° 17 Martel, avocat, 1301, St-Viateur ouest.Outre-mont, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous lc nom de « Gestion Real Ixturcnce ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 6 actions ordinaires de $100 chacune, 3,937 actions privilégiées classe « A » dc $10 chacune et en 30 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 4371, Gatineau, Laval, district judiciaire dc Montréal.Le salit-ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 64-1970 Gestion René* Laurence ltée Le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1970, constituant en corporation: René Laurence, constructeur, Lucille Perreault, ménagère, épouse dudit René Laurence, tous deux de 685, Rivière sud, Saint-Eustache, et Germain Laurence, constructeur, 4330, Louis Payette, Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portc-feuille, de placement et dc gestion, sous le nom de « Gestion René Laurence ltée », avec un capital total dc $40,000, divisé en 10 actions ordinaires dc $100 cliacunc, 3,896 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 40 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 685, Rivière sud, Saint-Eustache, district judiciaire de Terre-bonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 67-1970 Global Importers Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Essiy Fink, rentier, Martin Bruscloff, tous deux du 938, rue Francis, Longueuil, et John Stefan, 462, rue Rachel, Montréal, ces deux derniers marchands, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de plats et porcelaine allant au four, de verrerie, dc porcelaine, de bijoux et d'accessoires vestimentaires de tout genre, sous le nom de « Global Importers Ltd.», avec un capital de $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 462 est, rue Rachel, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 202-1970 Le Granby Bar inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc février 1970, constituant en corporation: Pierre Mercure, hôtelier, 37, Principale, St-Viatcur, West, Outremont, for the following purposes: To carry on business as a holding investment and management company, under the name of \"Gestion Réal Laurence ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 6 common shares of $100 each, 3.937 class \"A\" preferred shares of $10 each arid 30 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 1371 Gatineau, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 64-19711 Gestion René\" Laurence ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: René Laurence, builder, Lucille Perreault, housewife, wife of the said René Laurence, both of 685 Rivière south.Saint-Eustache, and Germain Laurence, builder, 4330 Louis Payette, Laval, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Gestion René Laurence ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10 common shares of $100 each, 3,896 preferred class \"A\" shares of $10 each and 40 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at 685 Rivière south, Saint-Eustache, judicial district of tcrrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 67-197(1 Globul Importers Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Essiy Fink, gentleman, Martin Bruscloff, both of 938 Francis Street, Longueuil.and John Stefan, 462 Rachel Street, Montreal, the latter two merchants, for the following purposes: To manufacture and deal in ovenwurc, glassware, chinaware, jewellery, wearing apparel of every type, under the name of \"Global Importers Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 46.' Rachel Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 202-1970 Le Granby Bar inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Mercure, innkeeper, 37 Principale, Aline St-Cyr, manager, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2435 Aline St-Cyr, gérante, 800, Principale, et Colette Brodeur, secrétaire, 37, Principale, ces deux dernières filles majeures, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges, restaurants et salles à manger, sous lc nom dc « Lc Granby Bar inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions de catégorie « A » ayant une valeur de $100 chacune et en 100 actions de catégorie « B » ayant une valeur \u2022le $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Granby, district judiciaire dc Bedford.Ix sou.i-mini.ilre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-philippe Bouchard.34173-0 97-1970 Griffe de Paris inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc lu première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Louis Orcnstein, 5654, avenue Macdonald, Hampstead, Jason Ruby, 47, Place du Bois, Dollard-dcs-Ormeaux, tous deux avocats, et (ilucia Miller, secrétaire, fille majeure, 3201, avenue Forest Hill, Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc vêtements féminins de toutes sortes, sous le nom de « Griffe de l'a ris inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1500, rue Stanley, bureau 430, Montréal, district judiciaire de Montréal.I.r sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pm lippe Bouciiahd.34173 47-1970 Michel Guertin inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu crles ou accidents, déterminer le montant des pertes ou estimer les dommages causés par accidents ou sinistres, et négocier les règlements des réclamations, sous lc nom de « M!.E.King Claims Adjusters Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 353, rue Saint-Nicholas, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 212-1970 5th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice Barrette, 7935 de Normanville, Lucien Desmarais, 8905 Lajeunesse, Diane Gravel, spinster of the full age of majority, 2567 Beaubien, René Dubuc, 8780 St-Urbain, Jacques Grégoire, 10887 Pie IX Boulevard, all five veterinaries, and Gisèle Ducharme, veterinary technician, wife of Pietro Salvati, 10926 St-Laurent, all of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Investissements Félicynophyliqucs (F.C.) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 996 common shares of $1 each and into 39,004 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 9988 Lajeunesse Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 4582-1969 Les Investissements M.L.T.G.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mauricc-E.Lagucé, 4150 Trafalgar Road, Montreal, Serge-D.Tremblay, 8515 Bonnivet Street, Saint-Léonard, and Michel Lassonde, 612 Vauquelin Street, Beloeil, all three advocates, for the follow-wing purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Les Investissements M.L.T.G.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 3245 Côte Terrebonne Road, Terrebonne, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 5513-1969 M.E.King Claims Adjusters Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mario Emile King, insurance adjuster, LaConnelly Boulevard, Rural Route 1, Saint-Hippolyte, Sidney Cutler, 5767 Glenardcn, Côte Saint-Luc, and Moe Ackman, 26 Aldrcd Crescent, Hampstead, the latter two advocates, for the following purposes: To investigate losses or accidents, assess losses or estimate damages thereby caused and to negotiate settlements of any claims, under the name of \"M.E.King Claims Adjusters Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 353 St.Nicholas Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 212-1970 2440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n\" 17 Laboratoires Bio cliniques inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Bertrand Lacombe, 262, Bleignier, Saint-Laurent, Michel Lassonde, 612, Vauquelin, Beloeil, et Scrge-D.Tremblay, 8515, rue Bonnivet, Sain l -Léonard, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire des analyses, des examens et des recherches dc toutes sortes, sous le nom de « Laboratoires Bio clinicilies inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $10 chacune et en 370 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 4146, rue Bélanger est, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sotis-minislre tien institutions financières, compagnies el coopéralires, Ls-Piiii.ippk Bouciiahd.34173-0 34-1970 Laiterie Bélanger & fils liée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Emile Bélanger, laitier, Robert Bélanger, technicien, et Raymond Bélanger, camionneur, tous trois de Mont-Laurier, pour les objets suivants: Exploiter une laiterie dans toutes ses spécialités, sous le nom dc « Laiterie Bélanger & fils ltée », avec un capital total de $75,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 550 actions privilégiées dc $100 chacune.I*e siège social dc la compagnie est ù Mont-Laurier, district judiciaire de Labcllc.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173-o 5817-1969 Lara Shops Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la lx>i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Irving Adessky, 56, Heath Place, Hampstead, Harry Blank, 4625, avenue Miller, Sol Apel, 2657, Ekers, tous deux dc Montréal, tous trois avocats, etFrancine Ladouceur, secrétaire, célibataire, 103, 25e rue, Saint-Eustache, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce d'accessoires vestimentaires, vêtements et marchandises de toutes sortes, sous le nom de « Lara Shops Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 115-1970 Yves Lau/.on & fils inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu Laboratoires Bio cliniques inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bertrand Lacombc, 262 Bleignier, Saint-Laurcnl, Michel Lassonde, 612 Vauquelin, Beloeil, mid Sergc-D.Tremblay, 8515 Bonnivet Street, Saint-Léonard, all three advocates, for the following purposes: To carry on analyses, examinations and research of all kinds, under the name of \"Laboratoires Bio cliniques inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $10 each and into 370 preferred shares of $101) each.The head office of the company is at 4146 Bélanger Street East, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 34-1970 Laiterie Bélanger & fils ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Emile Bélanger, dairyman, Robert Bélanger, technician, and Raymond Bélanger, trucker, all three of Mont-Laurier, for the following purposes: To operate a dairy in all its specialties, under the name of \"Laiterie Bélanger & fils ltée\", with a total capital stock of $75,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 550 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Monl-Laurier, judicial district of Laiiclie Ls-Philippe Bouciiahd.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5817-1909 Lara Shops Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving Adessky, 56 Heath Place, Hampstead, Harry Blank, 4625 Miller Avenue, Sol Apel, 2657 Ekcrs.both of Montreal, all three advocates, and Fran-cine Ladouceur, sccrtary, spinster, 103, 25th Street, Saint-Eustache, for the following purposes: To manufacture and deal in wearing apparel, clothing and merchandise of all kinds, under the name of \"Lara Shops Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiahd, ¦Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 115-1970 Yves Lauzou & fils inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2441 île lu premiere partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Yves Lauzon, commerçant, Denise Sicard, ménagère, épouse dudit Yves Lauzon, et Pierre-Luc Lauzon, comptable, tous trois de Mont-Laurier, pour les objets suivants: Faire le commerce dc bière, porter, incluant eau minérale, liqueurs douces et autres breuvages alcooliques ou non et leurs sous-produits, sous le nom de « Yves Lauzon & fils inc.», avec un capital total dc $125,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 115,000 actions privilégiées dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Mont-Laurier, district judiciaire dc Labcllc./.our les objets suivants: Manufacturer toutes sortes de produits, articles et marchandises, en faire le commerce, sous le nom de « Maison Joseph Battat liée », avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune Lorilou Stables Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Coin-panics and Cooperatives, incorporating: Vincent Petrilli, merchant, Sharon Petrilli, housewife, wife of the said Vincent Petrilli, both of 118 Caruso Street, Dollard-dcs-Ormcaux, Joseph Nittolo, 969 Clifton Street, Montreal, and Jack Pctrilli, 111 St.Patrick Square, Chutcauguay, the latter two merchants, for the following purposes : To improve the breed and promote the breeding, under the name of \"Lorilou Stables Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 5483 St.Jumes Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Pihmppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173-o 326-1970 The Macdonald College Faculty Club Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of Febniary, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert M.Gill, Huntingdon, Harold C.Gibbs, Choisy, Barry Pavitt, 2111 Marlowe Avenue, Montreal, Diane Raymond, spinster, 69 Circle Road, Bcaconsficld, Roger Knowles, 84 Oxford Road, Rol>crt O.Hawes, 8 Combridgc Road, both of Baie d'Urfé, J.Roger Bidcr, 1 Stewart Park, all seven professors, Edith Hunter, secretary, spinster, 42 Perrault Avenue, both of Snintc-Anne-de-Bellcvue, und Mark Waldron, director, 34 Muir Park Circle, Senneville, for the following purposes: To permit social friendship and unity among its members, under the name of \"The Macdonald College Faculty Club\".The amount to which the value of the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $50,000.The head office of the corporation is at Saintc-Annc-dc-Bellcvue, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173-0 1916-1969 Maison Joseph Battat Itcc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Isaac Battat, importer, 2305 Lucerne Road, Mount Royal, Jack Boidman, 4875 Dufferin Road, Montreal, and Moe Ackman, 26 Aldred Crescent, Hampstead, the latter two advocates, for the following purposes: To manufacture ami deal in all kinds of products, urticlcs and merchandise, under the name of \"Maison Joseph Battat ltée\", with a total capital stock of $40,000.divided inlo>10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each. 2444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1070, 102' année, «° 17 Le siège social de la compagnie est 1193, carré Phillips, bureau 5, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173 ¦ 159-1970 Maisons Mobiles Riviera ltée Riviera Mobile Homes Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres patentes, en date du 28e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Femand-0.Charettc, homme d'affaires, 1765, rue Boudrias, Saint-Laurent, B.-Philippe Charettc, menuisier, 45, Bellevue, Gatineau, Nar-cisse-S.Charettc, mécanicien, route rurale numéro 1, Pointe-Gatineau, et Jean-Denis Cliarettc, instituteur, 58, Des Flandres, Touraine, pour les objets suivants: Faire lc commerce de maisons mobiles (roulottes), sous lc nom dc « Maisons Mobiles Riviéra ltée \u2014 Riviéra Mobile Homes Ltd.», avec un capital total «le S50.000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Tcmplcton-Ouest, district judiciaire de Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173-o 375-1970 Guy Malenfant sports inc.Lc ministre des institutions financières, .compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Guy Malenfant, représentant, Monique Rousseau, ménagère, épouse d'André Castonguay, tous deux dc 117, rue Laval, et Jeanne-Ida Lemay, ménagère, épouse de Leopold Castonguay, 22, Pouliot, tous trois dc Rivièrc-du-Loup, pour les objets suivants: Faire lc commerce dc bicycles, tricycles, aéroplanes, automobiles, auto-neige, canots-automobile ou autres embarcations nautiques, sous le nom de « Guy Malenfant sports inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Rivièrc-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 7-1970 Manie Electric Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Guy Boisvert, électricien, Luce Bouchard, ménagère, épousé dudit Guy Boisvert, tous deux de 1354, I.ufontainc, et Pierre Lalande, avocat, 1, Place Laval, suite 305, tous trois dc Laval, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens et faire lc commerce et l'entretien de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom de The head office of the company is at 1193 Phillips Square, suite 5, Montreal, judicial district'of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies aiul Cooperatives.34173-0 159-1970 Maisons Mobiles Riviéra ltée Riviéra Mobile Homes Ltd.Notice is given tliat under Part I of Ihc Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fcrmmd-O.Charettc, businessman, 1765 Boudrias,StreeI, Saint-Laurent, B.-Philippe Charettc, carpenter, 45 Bellevue, Gatineau, Narcisse-S.Charettc, mechanic, Rural Route number 1, Pointc-Gali-ncau, and Jean-Denis Charettc, professor, 58 Des Flandres, Touraine, for the following purposes: To deal in mobile homes (trailers), under the name of \"Maisons Mobiles Riviéra ltée \u2014 Riviéra Mobile Homes Ltd.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 common shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Templctou West, judicial district of Hull.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 375-1970 Guy Malenfant sports inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have licen issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Malenfant.representative, Monique Rousseau, housewife, wife of André Castonguay, both of 117 Laval St.and Jeanne-Ida Lcmay, housewife, wife of Leopold Castonguay, 22 Pouliot, all three of Rivièrc-du-Loup, for the following purposes: To deal in bicycles, tricycles, airplanes, automobiles, snow-mobiles, motor boats or other water craft, under the name of \"Guy Malenfant sports inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Rivièrc-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 7-1970 Manic Electric Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Boisvert, electrician, Luce Bouchard, housewife, wife of the said Guy Boisvert, both of 1354 Lafontui-ne, and Pierre Lalande, advocate, 1 Place Laval, Suite 305, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as electricians, and to deal in and repair all kinds of electrical appliances and accessories, under the name of \"Manic QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2445 « Manic Electric Ltd.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.I .c siège social de la compagnie est 1354, Lafon-laine, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 5894-1969 Electric Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred sharsc of $10 each.The head office of the company is at 1354 Lafontainc, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 5894-1969 Manoir Mont-St-Iiilaire Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour dc janvier 1970, constituant en corpora-lion sans capital-actions: Fabien Rioux, gérant, 2S8, boulevard Richelieu, Saint-Mathias, René I.eclair, comptable, 7, Charlevoix, Roger Varnier, évaluateur, 35, De Beaujeu, René Morin, fonctionnaire, 165, Des Érables, et Fernand Lcgault, ollicicr de douanes, 160, Gaboury, ces quatre derniers dc Mont-Saint-Hilaire, pour les objets suivants: Venir en aide aux personnes Agées et aux personnes seules en matière d'hébergement et de pension, sous le nom dc « Manoir Mont-St-llilairc Inc.».Ix; montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $1,000,000.Le siège social dc la corporation est à Mont-Saint-Hilaire, district judiciaire «le Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 6081-1969 Manoir Mont-St-Hilaire Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Fabien Rioux, manager, 288 Richelieu Boulevard, Saint-Mathias, René Ix\"clair, accountant, 7 Charlevoix, Roger Varnier, estimator, 35 De Beaujeu, René Morin, civil employee, 165 Maple, and Fernand Lcgault, custom officer, 160 Gaboury, the latter four of Mont-Saint-Hilaire, for the following purposes: To help the aged and single persons by providing shelter and board, under the name of \"Manoir Mont-St-Hilairc Inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is $1,000,000.The head office of the corporation is at Mont-Saint-Hilaire, judicial district of Saint-Hyacinthc.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6081-1969 G.Marshall Siev Inc.Ix; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ¦ le la première partie de lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jack Lightstone, 68, Stratford, Hampstead, Morlin A.Aster, 6525, Côte Saint-Luc, et Marvin Riback, 5621, Palmer, ces deux derniers de Côte Suint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire lc commerce de meubles et dc fantaisies et nouveautés d'ameublement de toute description, sous le nom dc « G.Marshall Siev Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 200 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 3620, Ridgewood, bureau 612, Montréal, district judiciaire de Montréal.Ij: sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 334-1970 G.Marshall Siev Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jack Light-stone, 68 Stratford, Hampstead, Morlin A.Aster, 6525 Côte St.Luc, and Marvin Riback, 5621 Palmer, the latter two of Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To deal in furniture and furniture novelties of every description, under the name of \"G.Marshall Siev Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 3620 Ridgewood, Suite 612, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173-o 334-1970 Martel Detroit Diesel Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation : Edward Martel, gérant de district, Eunice Hughes, maîtresse dc maison, épouse dudit Martel Detroit Diesel Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edward Martel, district manager, Eunice Hughes, housewife, wife of the said Edward Martel, both of 2446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n° 17 Edward Martel, tous deux du 2364 Ogilvy Road, Ottawa, Province of Ontario, et Kenneth Martel, expert comptable, 1020, 3c avenue, Verdun, pour les objets suivants: Faire le commerce de moteurs diesel et d'équipement de construction, sous lc nom de « Martel Detroit Diesel Limited », avec un capital total dc $40,000, divisé en 40,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Hull, district judiciaire dc Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 6291-1969 Frank Martel Moving & Storage Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de janvier 1970, constituant en corporation: François Martel, 51, Maisonncuw, Hector Robert, 6, Lionel-Groulx, tous deux hommes d'affaires, et Fcrnand Larosc, notaire, tous trois de Pointc-Gatincau, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc transport, sous le nom dc « Frank Martel Moving & Storage Ltd.», avec un capital total dc $20,000, divisé en 200 actions ordinaires dc $100 chacune.Le siège social de la compagnie est ù Pointc-Gatincau, district judiciaire dc Hull.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 5508-1969 J.H.Maxwell Mfg.Inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour dc janvier 1970, constituant en corpora t ion : Stanley Safe, 2, square Westmount, app.1001, Westmount, James Doherty, 107, Bedford, Baie-d'Urfé, John H.Maxwell, 1400 ouest, avenue des Pins, tous trois administrateurs, et Benjamin J.Grecnberg, avocat, 4211 Grand Boulevard, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc toutes sortes dc machinerie, équipement, outils, accessoires, neufs ou usagés, et d'autres lignes dc marchandises du même genre, sous le nom dc « J.H.Maxwell Mfg.Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 3,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 495-1970 McCoy Lake Mines Limited (No personal liability) Les Mines du Lac McCoy limitée (Libre dc responsabilité personnelle) Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de janvier 1970, constituant en corporation.2364 Ogilvy Road, Ottawa, Province of Ontario, and Kenneth Martel, auditor, 1020, 3rd Avenue, Verdun, for the following purposes: To deal in diesel engines and construction equipment, under the name of \"Martel Detroit Diesel Limited\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of si each.The head office of the company is lit Hull, judicial district of Hull.Ls-Piiilippe Boucuaud, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérât ires.34173-o 6291-1909 Frank Martel Moving & Storage Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Francois Martel, 51 Maisonncuvc, Hector Robert, li Lioncl-Groulx, both businessmen, und Fernuiul Larose, notary, all three of Pointc-Gatincun.for the following purposes: To carry on business as a transport coinpuy, under the name of \"Frank Martel Moving &\u2022 Storage Ltd.\", with a total capital stock of $20,000, divided into 200 common shares of $100 each.The head office of the company is ut Pointc-Gatincau, judicial district of Hull.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 5508-1909 J.H.Maxwell Mfg.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives, incorporating: Stanley Safe, 2 Westmount Square, Apt.1001, Westmount.James Dohcrty, 107 Bedford, Baic-d'Urfé, John H.Maxwell, 1400 Pine Avenue West, all three executives, anil Benjamin J.Grecnberg, advocate, 4211 Grand Boulevard, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all types of new an.i used machinery, equipment, tools, accessories and other similar or allied lines of merchandise, under the name of \"J.H.Maxwell Mfg.Inc.\", with u total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 495-1970 McCoy Lake Mines Limited (No personal liability) Les Mines du Lac McCoy limitée (Libre de responsabilité personnelle) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 Guy-E.Boisvert, 4976, Glencairn, Montréal, G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505, Moore, Laval, tous trois avocats, Denyse Marcoux, 1488, Gait, Montréal, et Louise Dclorme, 350, avenue des Pins, Saint-Lambert, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce du gaz naturel, du pétrole, dc l'huile et de leurs produits et sous-produits, sous le nom de « McCoy Lake Mines Limited » (No personal liability) \u2014 « Les Mines du Lac McCoy limitée » (Libre de responsabilité personnelle), avec un capital total de 85,000,000, divisé en 5,000,000 actions ordinaires de 81 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 172-1970 Mibar (Quebec) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de février 1970, constituant en corporation: Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, Gordon Echenberg, 1545, avenue McGregor, tous deux dc Montréal, Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, et Jonathan Chait, 4, Surrey Gardens, Westmount, tous quatre avocats, |K>ur les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de placement et de portefeuille, sous le nom île « Mibar (Québec) Inc.», avec un capital total de 8700 divisé en 700 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 cliacune.Le siège social dc la compagnie est 1, Place Ville Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 626-1970 .Midtown Auto Park Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1970, constituant en corporation: George Polydoropoulos, 211 ouest, rue Mont-Royal, app.2, Montréal, Leon Cynamon, 5501, Adalbert, app.1011, tous deux gérants, et Harold Gossack, avocat, 5761, Honoré de Balzac, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exploiter des stations-service, des autoparcs et des garages pour le stationnement, sous le nom de « Midtown Auto Park Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 cliacune.Le siège social de la compagnie est ù Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 476-1970 Montréal Est sport limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu 2447 Guy-E.Boisvert, 4976 Glencairn, Montreal, G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, all three advocates, Denyse Marcoux, 1488 Gait, Montreal, and Louise Delorme, 350 Pinc Avenue, Saint-Lambert, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in natural gas, petroleum, oil and their products and by-products, under the name of \"McCoy Lake Mines Limited\" (No personal liability) \u2014 \"Les Mines du Lac McCoy limitée\" (Libre de responsabilité personnelle), with a total capital stock of 85,000,000, divided into 5,000,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 172-1970 Mibar (Québec) Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, Gordon Echenberg, 1545 McGregor Avenue, both of Montreal, Robert Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, and Jonathan Cliait, 4 Surrey Gardens, Westmount, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Mibar (Québec) Inc.\", with a total capital stock of 8700, divided into 700 common shares of the par value of 81 each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie, suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 626-1970 Midtown Auto Park Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: George Polydoropoulos, 211 Mount Royal Street West, Apt.2, Montreal, Leon Cynamon, 5501 Adalbert, Apt.1011, both managers, and Harold Gossack, advocate, 5761 Honoré de Balzac, the latter two of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To operate service-stations, parking lots and parking garages, under the name of \"Midtown Auto Park Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 476-1970 Montréal Est sport limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 de la première partie de lo Loi «les compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Claude Vanier, commerçant, Marguerite Vanier, ménagère, épouse dudit Claude Vanier, tous deux dc 2920, Fletcher, Montréal, et Pierre IahIuc, comptable, 58, 5c Avenue, Roxboro, pour les objets suivants: Exploiter une boutique de sports, sous le nom dc « Montreal Est sport limitée », avec un capital total dc S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires de S10 ebucune et en 100 actions privilégiées de $100 chacune.\\x siège social dc lu compagnie est 2920, rue Fletcher, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 273-1970 Morin construction inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en «late du 30c jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Durie Brunct, entrepreneur en construction, 353, rue Bédard, Vanier, province d'Ontario, F^ddy Piché, comptable, 43, rue Tours, Touraine, et Lucien Philippe, mécanicien, 14, rue I .éopold.Pointc-Gatincau, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et dc construction, sous le nom de « Morin construction inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur nominale et en 30,000 actions privilégiées dc SI chacune Le siège social dc lu compagnie est ù Pointc-Gatincau, district judiciaire de Hull.Le sous-ministre rue La]k>rte, Québec, Thérèse Gossclin, épouse de Yves Villeneuve, 772, Place Philippe, Sainte-Foy, et Micheline René, épouse dc Clarence Boutin, 81, de l'Avenir, Beauport, toutes trois secrétaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom dc « Olna Investments Ltd.*, avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173-6 512-1970 Olna Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marguerite Poirier, spinster of the full age of majority, 311 j Laportc Street, Québec, Thérèse Gosselin, wife of Yves Villeneuve, 772 Philippe Square, St.Foy.and Micheline René, wife of Clarence Boutin.81 de l'Avenir, Beauport, all three secretaries, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction and investment company, under the mime of \"Olna Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 512-1970 O-RA-L-0 inc.I-c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Charles-Emile Blouin, homme d'affaires, Kathleen Kcefer, ménagère, épouse dudit Char-les-Fanilc Blouin, tous deux de 1211, de Samos, Sillery, Gilles Thivierge, restaurateur, et Liliane Blanchet, ménagère, épouse dudit Gilles Thivierge, ces deux derniers de 302, St-Sauveur, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « O-RA-L-0 inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 296-1970 O-RA-L-0 inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Charles-Emile Blouin, businessman, Kathleen Kcefer, housewife, wife of the said Charles-Emile Blouin, both of 1211 de Samos, Sillery, Gilles Thivierge, res taurateur, and Liliane Blanchet, housewife, wife of the said Gilles Thivierge, the latter two of 302 St-Sauveur, Québec, for the following purposes : To carry on business us restaurateurs, under the name of \"O-RA-L-O inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,00(1 common shares of $10 each.The head office of the company is nt Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 296-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2451 O.T.J.Stc-Marthc inc.I.r ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du I8e jour de février 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Lachance, fureur, 413, rue St-Laurent, Fernand Laçasse, Imilcur, 156, rue Couture, Fernand Baillargeon, contremaître, 88, rue Turcotte, Fernand Belle-ntare, assureur, 213, rue Itoily, Jean-Paul Gagné, régisseur, 1196, rue Blanchet, René I,etarte, ingénieur professionnel, 458, rue des Érables, Roger Martincau, technicien en laboratoire, 1142, rue Jeanne Mance,.Adril St-Cyr, constable, 511, rue des Érables, et Bernard Landry, notaire, 1260, rue d'Youvillc, tous dc Thctford Mines, pour les objets suivants: 1,'organisation des loisirs, sous le nom dc O.T.J.Stc-Marthc inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder lu corporation, est de $100,000.Le siège social dc lu corporation est ù Thctford Mines, district judiciaire dc Mégantic./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 749-1970 O.T.J.Stc-Marthc inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Marcel Lachance, driller, 413 St-Laurent St., Fernand Laçasse, oilman, 156 Couture St., Fernand Baillargeon, foreman, 88 Turcotte St., Fernand Bellemare, underwriter, 213 Boily St., Jean-Paul Gagné, manager, 1196 Blanchet St., René Letarte, professional engineer, 458 des Érables St., Roger Mnrtincuu, laboratory technician, 1142 Jeanne Mancc St., Adril St-Cyr, constable, 511 des Érables St., and Bernard Landry, notary, 1260 d'Youville St., all of Thctford Mines, for the following purposes: The organization of recreational activities, under the name of \"O.T.J.Sir-Mart he inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire und hold is to be limited, is $100,000.The head office of the corporation is at Thctford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 749-1970 P.G.auto location liée Le ministre des institutions finuncières, com-pugnics et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc lu Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 30c jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Denis Hardy, avocat, 1315, rue Jules Poitras, Saint-Laurent, Jean-Pierre Durochcr, notaire, 35, rue Montsec, Lorraine, et Yvette Fortin, secrétaire, fille majeure, 120, Équcrrc, Laval, l>our les objets suivants: Fuirc affaires comme garagistes et faire le commerce et la location d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « P.G.auto location ltée », avec un capital total dc $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de $1 chacune et en 390 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 110, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 424-1970 l'.G.auto location liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denis Hardy, advocate, 1315 Jules Poitras Street, Saint-Laurent, Jean-Pierre Durocher, notary, 35 Montsec Street, Lorraine, and Yvette Fortin, secretary, spinster of the full age of majority, 120 Êquerre, Laval, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in and rent automobiles, motors, machines and ull their accessories and parts, under the name of \"P.G.auto location ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and into 390 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 110 Turgeon Street, Sainte-Thérèse, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 424-1970 P.R.Finance inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a été accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Sydney Lazarovitz, 984, Mont St-Denis, Sillery, Jules Bernatchez, 8170, de Vienne, Charlesbourg, et Jean McNicoll, 2529, Gregg, Sainte-Foy, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme prêteurs d'argent, sous le nom dc « P.R.Finance inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.P.R.Finance inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have l>een issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sydney Lazarovitz, 984 Mont St-Denis, Sillery, Jules Bernatchez, 8170 de Vienne, Charlesbourg, and Jean McNicoll, 2529 Gregg, St.Foy, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as money lenders, under the name of \"P.R.Finance inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and into 200 preferred shares of $100 each. 2452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 85 avril 1970, 108' année, n° 17 Le siège social de la compagnie est 3208, Carré Bochart, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 481-1970 P.V.C.Isolation inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de février 1970, constituant en corporation: Gérard Tremblay, contremaître, 8386, rue Boyce, Jacques Tremblay, entrepreneur, 4579, rue Beau-bien est, et Edith Dupuis, secrétaire, épouse dc Raymond Tcllier, 4677, rue Migneault, tous trois de Montréal, i>our les objets suivants: L'isolation dans tous les domaines, soit ceux dc la mécanique, de la construction ou dc tous autres métiers et disciplines, sous le nom dc « P.V.C.Isolation inc.», avec un capital total de S40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 cliacune.Lc siège social dc la compagnie est 1500, rue Aylwin, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 456-1970 Pagode Tours Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de février 1970, constituant en corporation : André Vannerum, agent d'affaires, Gilbçrte De-coeur, ménagère, épouse dudit André Vannerum, tous deux de 5515, rue Bellcrive, Brassard, et Gilles Chiquette, avocat, 849, rue Honfleur, Longueuil, pour les objets suivants: Exploiter des ugences dc billets et des bureaux de tourisme, sous le nom de « Pagode Tours inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est Édifice de la Station du Métro, Longueuil, district judiciaire de Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pmlippe Bouchard.34173-0 492-1970 Pamikc Mines Limited (No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Edward O.Dearden, géologue, 11, Tallforest Crescent, Edward Law, administrateur, 99, Mill Road, tous deux de Etobicoke, province d'Ontario, Thomas Daniel O'Connor, gérant des ventes, 82, avenue Fuller, Toronto, province d'Ontario, G.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, et Claude Boisvert, 1505, Moore, Laval, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Faire de la prospection et de l'exploration pour trouver des mines et des minéraux, sous le nom de « Pamike Mines Limited » (No personal The head office of the company is at 320S Bochart Square, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 481-1971) P.V.C.Isolation inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Tremblay, foreman, 8386 Boyce Street, Jacques Tremblay, contractor, 4579 Beaubien Street East, and Edith Dupuis, secretary, wife of Raymond Tellier, 4677 Migneault Street, all three of Montreal, for the following purposes: Insulation in all its fields, including mechanics, construction or all other trades and disciplines, under the name of \"P.V.C.Isolation inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,001) common shares of $10 each.The head office of the company is at 1500 Aylwin Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3-1173 456-1970 Pagode Tours Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Vannerum, business agent, Gilberte Decoeur, housewife, wife of the said André Vannerum, both of 5515 Bellerive St., Brassard, and Gilles Chiquette.advocate, 849 Honfleur St., Longueuil, for tin-following purposes: To operate ticket and travel agencies, under the name of \"Pagode Tours Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at the Metro Station Building, Longueuil, judicial district of Montreal.Ls-PhiLi ppe Booch ard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 492-1971) Pamikc Mines Limited (No personal liability) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Edward O.Dcarden, geologist, 11 Tallforest Crescent, Edward Law, executive, 99 Mill Road, both of Etobicoke, province of Ontario.Thomas Daniel O'Connor, sales manager, 82 Fuller Avenue, Toronto, province of Ontario.G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, anil Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, the latter two attorneys, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"Pamike Mines Limited\" (No personal liability), with a total capital QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2453 liability), avec un capital total de 85,000,000, divisé en 5,000,000 actions ordinaires de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 10, rue Suint-Jacques, bureau 1003, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies tt coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173 35-1970 Park'n Fly of Montreal, Ltd.Ix; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour dc janvier 1970, constituant en corporation : Theodore P.Dcsloge junior, détenteur de biens immobiliers, 39, Picardy Lane, Gideon H.Schiller, avocat, 13, Upper Barnes Boad, tous deux de l.adue, et Martin J.Bloom, constructeur, 18, Sackston Woods Lane, Crevé Coeur, tous trois de Missouri, U.S.A., pour les objets suivants: Exploiter des terrains de stationnement commerciaux, sous le nom de « Park'n Fly of Montreal, Ltd.», avec un capital total de S20.000, divisé en 200 actions ordinaires dc §100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 55, «l'Au-Icuil, Québec, district judiciaire de Québec.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Piiilippe Bouciiahd.14173 872-1970 Pclavo inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Jean-Paul Perreault, 418, boulevard Quinn, Jacques Lnforest, 423.rue Benoît, tous deux dc Longueuil, et Réal Provost, 803, Louis Nor-mandin, Boucherville, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, sous lc nom de « Pclavo inc.», avec un capital lotal de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 200 actions privilégiées dc Si00 chacune.Ix; siège social de lu copagnic est 423, rue llenoît est, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouciiahd.34173-0 6293-1909 stock of 85,000,000, divided into 5,000,000 common shares of 81 each.The head office of the company is at 10 St.James Street, suite 1003, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliees.34173-0 35-1970 Park'n Fly of Montreal, Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Theodore P.Desloge junior, real estate investor, 39 Picardy Lane, Gideon H.Schiller, lawyer, 13 Upper Barnes Road, both of Ladue, anrl Martin J.Bloom, builder, 18 Sackston Woods Lane, Creve Coeur, all three of Missouri, U.S.A., for the following purposes: To operate commercial parking lots, under the name of \"Park'n Fly of Montreal, Ltd.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 200 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 55 d'Au-teuil, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliees.34l73-i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en daté du 26e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Marccl-J.-G.Beaumier, 3600, Place D'Au-leuil, Trois-Rivièrcs-Ouest, Robert Huard, 2497, boulevard Normand, et Frank G.Barakclt, 2385, De Cannes, app.2, ces deux derniers de Trois-Rivières, tous trois avocats, pour les objets suivants: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Place Dunant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,900 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $5 each.The head office of the company is at 826 Belvedere Street South, Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 227-1970 Placements Alouette inc.Alouette Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Andre Clossey, 190 Iberville Blvd., Rcpentigny, Luc Sigouin, 12072 Lacordairc St., Apt.6, Montreal North, both notaries, and Cécile Lajeunesse, secretary, wife of Marcel Boutin, 6529, 18th Ave, Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Placements Alouette inc.\u2014 Alouette Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 4997-1969 Les placements Gcstal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Alphonse (Béchir) Alepin, annuitant, Antoinette Sayegh, housewife, wife of the said Alphonse (Béchir) Alepin, both of 5859 LaSalle Blvd., Verdun, and Hélène Talbot, legal secretary, wife of Roger Talbot, 3183 Terrasse Sagard, Longueuil, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of 'Les placements Gestal inc.\", with a total capital stock of $S00, divided into S00 common shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at Verdun, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6038-1969 Placements Gomar inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marccl-J.-G.Beaumier, 3600 D'Auteuil Place, Trois-Rivières West, Robert Huard, 2497 Normand Boulevard, and Frank G.Barakett, 2385 De Cannes, Apt.2, the latter both of Trois-Rivières, all three advocates, for the following purposes: 2456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Placements Gomar inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 90, Des Casernes, Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIILIl>i'e Bouchard.34173-0 261-1970 Les placements J.F.R.M.ltée Ix: ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jacques Cartier, avocat, Madeleine Derome, ménagère, épouse dudit Jacques Cartier, tous deux de 305, Ire rue, Iberville, et Monique Cartier, fonctionnaire, veuve d'André Archamhault, 4866, avenue Wilson, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme conseillers en administration et faire affaires comme compagnie de |>orte-feuille, dc placement et de gestion, sous le nom dc « lx:s placements J.F.R.M.ltée », avec un capital total de $100,000, divisé en 100 actions ordinaires de $1 chacune, 9,960 actions privilégiées classe « A » de $10 chacune et en 300 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.Lc siège social de la compagnie est 215, rue Jacques Cartier, Saint-Jean, district judiciaire d'Ibervillc.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.34173-d 6050-1969 Les placements Lc Duc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc février 1970, constituant en corporation: Norbert Valiquette, commerçant, 6606, Louis Hébert, Guy Lafrcnayc, représentant, 3051, rue Lyall, et André-B.Ixi Grenade, comptable, 11405, rue Drouart, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement et de portefeuille, sous le nom dc « Les placements Ix; Duc inc.», avec un capital divisé en 100 actions ordinaires sans valeur nominale et en 1,500 actions privilégiées de $10 chacune Le siège social de la compagnie est à Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-o 6262-1969 Plomberie Benoit inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour de février 1970, constituant en corporation: Georges Benoit, maître-plombier, Claudette Houle, ménagère, épouse dudit Georges Benoit, tous deux de 1784, Georges, Laflêche, et Bertrand Baril, plombier, 1647, Joliette, app.6, Longueuil, pour les objets suivants: To carry on business as a holding company, under the name of \"Placements Gomar inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 90 Des Casernes, Trois-Rivières, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 261-1970 Les placements J.F.R.M.Itdc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Car-tier, advocate, Madeleine Derome, housewife, wife of the said Jacques Cartier, both of 305.1st St., Iberville, and Monique Cartier, civil servant, widow of André Arcliambault, 4866 Wilson Ave., Montreal, for the following purposes: To carry on business as management consultants, and to act as a holding, investment and management company, under the name of \"Les placements J.F.R.M.ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100 common shares of $1 each, 9,900 preferred class \"A\" shares of $10 each and 300 preferred class \"B\" shares of $1 each.The head office of the company is at 215 Jacques Cartier St., Saint John's, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6050-1900 Les placements Le Duc inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives, incorporating: Norbert Valiquette, trader, 6606 Louis Hébert, Guy Lafrc-naye, representative, 3051 Lyall Street, and André-B.La Grenade, accountant, 11405, Drouart Street, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an investment and holding company, under the name of \"Les placements Le Duc inc.\", with a capital stock divided into 100 common shares without nominal value and 1,500 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Longueuil.judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6262-1909 Plomberie Benoit inc.Notice is given that under Part 1 of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Benoit, master plumber, Claudette Houle, housewife, wife of said Georges Benoit, both 61 1784 Georges, Laflèchc, and Bertrand Baril, plumber, 1647 Joliette, apt.6, Longueuil, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 Faire affaires comme plombiers, sous le nom de « Plomberie Benoit inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $10 chacune et en 1.000 actions privilégiées d'une valeur nominale de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1784, rue (ieorgcs, I.allèche, district judiciaire de Montréal.Le nous-ministre des institutions financières, compagnies ci coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34I73-o 471-1970 Pro-Am Sports Consultants Ltd.Conseillers en sports Pro-Am ltée Le ministre des institutions financières, companies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour dc janvier 1970, constituant en corporation : Micheline Lnmarchc, 12, avenue Coolbreeze, l'ointe-Claire, Sandra E.Rochester, 1735, boulevard Édouard-Laurin, toutes deux secrétaires, célibataires, et Irene Stielow, secrétaire, épouse (('Alexander Stielow, 90, rue Crépeau, ces deux dernières de Saint-Laurent, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes d'articles de sport, dc vêtements et d'équipement pour le sport, sous le nom dc « Pro-Am Sports ( 'onsultants Ltd.\u2014 Conseillers en sports Pro-Am ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 336-1970 Les productions S.M.C.L.inc.S.M.C.L.Productions Inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de février 1970, constituant en corporation: \u2022lacques Clément, 3508, avenue Marcil, Jean-Pierre Bonin, 5550, Baldwin, tous deux dc Montréal, et Pierre Verdon, 3354, boulevard Gouin est, Montréal-Nord, tous trois avocats, l»ur les objets suivants: Faire le commerce de l'édition et de la sous-édition de chansons, sous le nom dc « Les productions S.M.C.L.inc.\u2014 S.M.C.L.Productions Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 300 actions ordinaires de $1 chacune et en 3,970 actions privilégiées de $10 chacune Lc siège social dc la compagnie est à Belocil, district judiciaire de Richelieu.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 223-1970 Les Produits Industriels motorises ltée Motorized Industrial Products Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres [latentes, en date du 27e jour de janvier 1970, constituant en corporation : 2457 To carry on business ns plumbers, under the name of \"Plomberie Benoit inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of a nominal value of $10 each and into 1,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 1784 Georges Street, Laflèche, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 471-1970 Pro-Am Sports Consultants Ltd.Conseillers en sports Pro-Am ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Micheline Lamarchc, 12 Coolbrceze Avenue, Pointe-Claire, Sandra E.Rochester, 1735 Edouard-Laurin Boulevard, both secretaries, spinsters, and Irene Stielow, secretary, wife of Alexander Stielow, 90 Crépeau Street, the latter two of Saint-Laurent, for the following purposes: To manufacture and deal in sporting goods, sports clothing and sporting equipment of all kinds, under the name of \"Pro-Am Sports Consultants Ltd.\u2014 Conseillers en sports Pro-Am liée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 336-1970 Les productions S.M.C.L.inc.S.M.C.L.Productions Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coojicratives, incorporating: Jacques Clément, 3508 Marcil Avenue, Jean-Pierre Bonin, 5550 Baldwin, both of Montreal, and Pierre Verdon, 3354 Gouin Boulevard East, Montreal North, all three advocates, for the following purposes: To deal in the publishing and sub-publishing of songs, under the name of \"Les productions S.M.C.L.inc.\u2014 S.M.C.L.Productions Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 300 common shares of $1 each and into 3,970 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Beloeil, judicial district of Richelieu.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 223-1970 Les Produits Industriels motorisés ltée Motorized Industrial Products Ltd.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters patent, bearing dute the 27th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incor|>orating: Yvon 2458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Yvon Jutras, commerçant, 2, Lavigne, Pierre Béliveau, gérant, 32, Alice, tous deux dc Victo-riaville, et Louise Leclerc, secrétaire, fille majeure, 2, Belleau, Arthabaska, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de moteurs ou parties dc moteurs pour des véhicules motorisés, sous lc nom dc « Les Produits Industriels motorisés ltée \u2014 Motorized Industrial Products Ltd.», avec un capital total dc 340,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de S10 chacune et en 250 notions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est à Victo-riavillc, district judiciaire d'Arthnbaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 372-1970 Progcsco inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Pierre Lalande, avocat, 1, Place Laval, Laval, Denise Valiquette, secrétaire, veuve de Georges Dagenais, 1681, Sauvé est, et Ginette Huncault, secrétaire, fille majeure; 7283, Berri, ces deux dernières, dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, dc construction, de placement et de portefeuille (holding), sous le nom de « Progresco inc.», avec un capital total de $50,000, divisé en 200 actions ordinaires de $20 chacune, 1,000 actions privilégiées classe « A » dc $1 chacune et en 4,500 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.1 .c siège social dc la compagnie est 5387, rue Amos, Montréal-Nord, district judiciaire «le Montréal.Lc sous-ministre des institutions financières, ^compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-d 6363-1969 Province of Québec Women's Field Hockey Association Inc.Association féminine dc Hockey sur gazon dc la province dc Québec inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Brigid MacTicr, institutrice, célibataire, 3601, Sainte-Famille, app.804, Joan Charman, infirmière, licenciée épouse de Hillary Don, 4866, Côte des Neiges, app.1502, toutes deux de Montréal, et Shcila McEvoy, commis de banque, épouse de Henry Kerin, 271, Saint-Louis, Dorval, pour les objets suivants: Co-ordonner l'expansion du hockey sur gazon dans la province de Québec, sous le nom de « Province de Québec Women's Field Hockey Association Inc.\u2014 Association féminine de Hockey sur gazon de la province de Québec inc.».Le.montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder et détenir la corporation est dc $1,000,000.Jutras, trader, 2 Lavigne, Pierre Béliveau, manager, 32 Alice, both of Victoriaville, and Louise Leclerc, secretary, spinster of the full age of majority, 2 Belleau, Arthabaska, for the following purposes: To manufacture and deal in motors or motor parts for motorized vehicles, under the name of \"Les Produits Industriels motorisés ltée \u2014 Motorized Industrial Products Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,5011 common shares of $10 each and 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Victoriaville, judicial district of Arthabaska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 372-1970 Progcsco inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Lalande, advocate, 1 Place Laval, Laval, Denise Valiquette, secretary, widow of Georges Dagenais, 1681 Sauvé East, and Ginette Huncault, secretary, spinster of the full age of majority, 7283 Bcrri, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Progresco inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 200 common shares of $20 each, 1,000 preferred class \"A\" shares of $1 each and into 4,500 preferred class \"B\" sliares of $10 each.The head office of the company is at 5387 Amos Street, Montreal North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 6363-1911(1 Province of Québec Women's Field Hockey Association Inc.Association féminine de Hockey sur gazon dc la province de Québec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Brigid MacTicr.teacher, spinster, 3601, Ste-Famille, Apt.SOI Joan Cliarman, registered nurse, wife of Hillary Don, 4866 Côte des Neiges, Apt.1502, both of Montreal, and Sheila McEvoy, bank clerk, wife of Henry Kerin, 271 St-Louis, Dorval, for the following purposes: To co-ordinate the development of field hockey in the Province of Québec, under the name of \"Province of Québec Women's Field Hockey Association Inc.\u2014 Association féminine de Hockey sur gazon dc la province de Québec inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the cor|x>rntion may hold or own is limited, is $1,000,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2459 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.e.sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe bouchard.34173 5663-1909 J.C.Prud'homme inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Jean-Claude Prud'homme, marchand de matériaux de construction, Nicole Aucoin, ménagère, épouse dudit Jean-Claude Prud'homme, tous deux de 279, rue St-Joseph, et Georges Prud'homme, commis, 960, Haute-Rivière, tous trois de Sainte-Martine, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction cl faire lc commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « J.C.Prud'homme inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 277, rue St-Joseph, Sainte-Martine, district judiciaire de llcauharnois./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 287-1970 Quebec Diversified Investments Ltd.Les Placements diversifiés du Québec liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie dc la Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 27e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Gùy-E.Boisvert, 4976, Glencairn, Montreal, (!.Harold Pickcl, 47, Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505, Moore, Laval, tous trois avocats, Dcnyse Marcoux, 1488, Galt, Montréal, et Louise Dclorme, 350, avenue des Pins, Saint-Lambert, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Fiercer les affaires d'une compagnie de portefeuille et dc placement, sous lc nom de « Québec Diversified Investments Ltd.\u2014¦ Les Placements diversifiés du Québec ltée », avec un capital-actions divisé en 10,000,000 d'actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173 368-1970 Québec Wood Shavings Incorporated Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi îles compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Harvey Frumkin, 5501, Adalbert, Allan Ë.Feld-inan, 6405, Lennox, tous deux avocats, de Montréal, et Larry Zaritsky, homme d'affaires, 17, boulevard Gagnon, Suint-Félicien, pour les objets suivants : L'industrie et le commerce dc « ripes » de bois et autres produits du bois, sous le nom de 'Québec Wood Shavings Incorporated', avec The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 5663-1969 J.C.Prud'homme inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Claude Prud'homme, dealer in building materials, Nicole Aucoin, housewife, wife of the said Jean-Claude Prud'homme, both of 279 St-Joscph Street, and Georges Prud'homme, clerk, 960 Haute-Rivière, all three of Sainte-Martine, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"J.C.Prud'homme inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 277 St-Joscph Street, Sainte-Martine, judicial district of Bcauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 287-1970 Quebec Diversified Investments Ltd.Les Placements diversifiés du Québec ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy-E.Boisvert, 4976 Glencairn, Montreal, G.Harold Pickcl, 47 Arlington, Westmount, Claude Boisvert, 1505 Moore, Laval, all three advocates, Dcnyse Marcoux, 1488 Gait, Montreal, and Louise Dclorme, 350 Pine Avenue, Saint-Lambert, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the numc of \"Québec Diversified Investments Ltd.\u2014 Les Placements diversifiés du Québec liée\", with a capital stock divided into 10,000,000 shares without par value The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 368-1970 Québec Wood Shavings Incorporated Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Harvey Frumkin, 5501 Adalbert, Allen E.Feldman, 6405 Lennox, both advocates, of Montreal, and Larry Zaritsky, businessman, 17 Gagnon Boulevard, Saint-Félicien, for the following purposes: To manufacture and deal in wood shavings and wood products, under the name of \"Québec Wood Shavings Incorporated\", with a total 2100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 un capital total dc $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 20,000 actions privilégiées dc $1 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, I.s-Philippe Bouchard.\" 34173 473-1970 Racz Taxi Center Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Sandor Racz, propriétaire dc taxi, 5735, Côte des Neiges, Irwin Block, gérant de garage, et Susan Kun, managère, épouse dudit Irwin Block, ces deux derniers dc 6300, rue Ixmnox, tous trois de Montréal, pour les ohjcts suivants: Établir et diriger une entreprises de taxis, sous le nom de « Racz Taxi Center Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 1201 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, district judiciaire de Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 131-1970 Kanvillc Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie tic la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de janvier 1970, constituant en corporation: John J.Wasscrman, 4790, Côte des Neiges, Harold S.Freeman, 5034, (ïrosvenor, tous deux avocats, et Jeannine Lemieux, secrétaire, épouse dc Fernand Tellier, 6626, Hurtcau, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeubles et dc construction, sous lc nom dc « Ranville Construction Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $1 chacune, 4,000 actions privilégiées classe « A » dc $1 chacune et 3,200 actions privilégiées classe « B » de $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppk Bouchard.34173 241-1970 Keno-Con ltée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour dc février 1970, constituant en corporation: Fernand Denis, entrepreneur, Jeanne d'Arc Caycr, ménagère, épouse dudit Fernand Denis, tous deux de 132, rue Lindberg, et Gaston Duro-cher, comptable, 193, avenue dc l'Aéroport, tous trois dc Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux dc construction, sous le nom de « Rcno-Con ltée », capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 473-197(1 Racz Taxi Center Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sandor Racz.taxi owner, 5735 Côte des Neiges, Irwin Block, garage manager, and Susan Kun, housewife, wife of the said Irwin Block, the latter two of 6300 Lennox Street, all three of Montreal, fur the following purposes: To carry on a taxi operating business, under the name of \"Racz Taxi Center Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1201 St.James Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173-o 131-19711 Ranville Construction Inc.Notice is given that under Part I of I he Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John .1.Wasscrman, 4790 Côte îles Neiges, Harold S.Freeman, 5034 Grosvcnor, both advocates, and ¦ lea11niue Lemieux, secretary, wife of Fernand Tellier, 6626 Hurteau, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Ranville Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $1 each, 4,000 class \"A\" preferred shares of $1 each ami 3,200 class \"B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 241-197(1 Rcno-Con ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fernand Denis, contractor, Jeanne d'Arc Caycr, liousewife.wife of said Fernand Denis, both of 132 Lindberg Street, and Gaston Durochcr, accountant.193 de l'Aéroport Avenue, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors and to deal in all kinds of building materials, under the name of \"Reno Con liée\", with n total capitul stock of $40,00(1. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April SB, 1970, Vol.10S, No.17 2461 avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc $1 chacune et en 20,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $1 chacune.I.c siège social dc la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.31173-0 564-1970 Restaurant à la Barrique inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1970, constituant en corporation : André Yiau, marchand, 10260, Cliambord, Montréal, Roger L'Heureux, mnttre-coiffcur, 4611, St-Joseph, Laval, et Denise Gervais, infirmière, c|k)usc de Rcynald Savoie, 11539, rue des Violettes, Montréal-Nord, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous lc nom de « Restaurant à la Barrique inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 1345, rue l'Ieury est, Montréal, district judiciaire de Mont-réal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopéralires, J.-Albert Gagnon*.34173-0 60-1970 Restaurant de l'auditorium de Verdun inc.Verdun Auditorium Restaurant Inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour dc janvier 1970, constituant en corporation : André Iatoux, commis dc bureau, 700, rue Melrose, Verdun, André Dnoust, représentant de commerce, et Lise Lavoie, ménagère, é|m>use dudit André Daoust, ces deux derniers dc 324, 90e avenue, LaSalle, pour les objets suivants : Faire affaires comme restaurateurs, sous lc nom de « Restaurant de l'auditorium de Verdun inc.\u2014 Verdun Auditorium Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est ù Verdun, district judiciaire dc Montréal.I.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3I173-0 374-1970 Restaurant Lc Buffet inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres putentes, en date du 12e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Michel Demers, courtier d'assurance, 57, Holliday, Paul-Armand Roy, commerçant, et Madeleine Dupuis, ménagère, épouse dudit Paul-Armand Roy, ces deux derniers de 172, Gamache, tous trois de Sept-Iles, pour les objets suivants: Exploiter des hôtels, tavernes, auberges et restaurants, sous le nom de « Restaurant Le Buffet inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.divided into 20,000 common shares of a nominal value of $1 each and 20,000 preferred shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is at Sherbrooke, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 564-1970 Restaurant à la Barrique inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Viau, merchant, 10260 Chambord, Montreal, Roger L'Heureux, master hairdresser, 4611 St-Joseph, Laval, and Denise Gervais, nurse, wife of Raynald Savoie, 11539 des Violettes St., Montreal North, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Restaurant à la Barrique inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1345 F'leury St.East, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Aluert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 60-1970 Restaurant de l'auditorium de Verdun inc.Verdun Auditorium Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Leroux, office clerk, 700 Melrose St., Verdun, André Duoust, business representative, and Lise Lu-voie, housewife, wife of the said André Duoust, the lutter two of 324, 90th Ave., LaSalle, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant de l'auditorium de Verdun inc.\u2014 Verdun Auditorium Restaurant Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is ut Verdun, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 374-1970 Restaurant I.c Buflet inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives, incorporating: Michel Demers, insurance broker, 57 Holliday, Paul-Armand Roy, trader, and Madeleine Depuis, housewife, wife of said Paul-Armand Roy, the latter two of 172 Gamache, all three of Sept-Ilcs, for the following purposes: To operate hotels, taverns, inns nnd restau-runts, under the name of \"Restaurant Lc Buffet inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each. 2402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SB avril 1970, 108' année, n° 17 Lc siège social de la compagnie est 405, rue lirocliu, Sept-Iles, district judiciaire de Haute-rive.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Mouchard.34173-0 118-1070 Restaurant Le Sabayon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première pnrtie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de février 1970, constituant en corporation: J.-Paul Robert, 1060, place d'Anjou, Saint-Bruno-dc-MontarvilIe, Stanley L.Sclingcr, 6265, avenue Mountain Sights, tous deux avocats, et Claire WHisky, secrétaire, célibataire, 3420, nie Hutchison, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: S'établir restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Le Sabayon inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 40,000 nctions ordinaires dc $1 chacune.Le siège social de la compagnie est 666 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIII.lPPE HOUCIIARD.34173 5872-1969 Restaurant L'Étape dc Magog inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour dc janvier 1970, constituant en corj>oration : Pierre Swolfs, restaurateur, Céline Martel, ménagère, épouse dudit Pierre Swolfs, tous deux dc 2110, Sherbrooke, et Jeanne Deniers, ménagère, veuve d'Anthimc Martel, 119, Merry sud, tous trois de Magog, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom dc « Restaurant L'Etape dc Magog inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinuires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Ia: siège social tic la compagnie est à Magog, district judiciaire dc Saint-F'rançois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Hi il l'Il a Kl).34173-0 33-1970 Rcxlcy's (1970) Inc.I.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Irving Reisler, marchand, 2275, Dcccllcs, Saint-Laurent, Edward Samuel Berger, avocat, et Judith Lccker, secrétaire, épouse de Kenneth Dollinger, ces deux derniers de 1010 ouest, Sainte-Catherine, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de vêtements sport, sous-vêtements et accessoires vestimentaires pour dames et pour hommes, sous le nom de « Rcxlcy's (1970) Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées dc $1 chacune.The head office of the company is at 405 Brochu Street, Scpt-Iles, judicial district of Hautcrive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173 118-UI70 Restaurant Le Salmyon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: J.-Paul Robert.1660 Place d'Anjou, Saint-Bruno-de-Montarvillr.Stanley L.Sclingcr, 6265 Mountain Sights Avenue, both advocates, und Claire Wilisky, secretary, spinster, 3420 Hutchison Street, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Le Sabayon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 40,000 common shares of $1 each.The head office of the company is at 666 Sherbrooke Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Phimppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Com/Millies and Cooperaliees.34173-0 5872-1000 Restaurant I 'I tape dc Magog inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Swolfs, restaurant-keeper, Céline Martel, housewife, wife of said Pierre Swolfs, both of 211(1 Sherbrooke, and Jeanne Deniers, housewife, widow of Antbinic Martel, 119 Merry South, all three of Magog, for the following pur|x>.ses: To carry on business as rcstaurunt-kec|x'rs under the name of \"Restaurant L'Éta|>c de Magog inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Magog, judicial district of Saint-François.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliees.34173 33-1070 Rcxlcy's (1970) Inc.Notice is given that under Purt I of I lie Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com panies ami Cooperatives, incorporating: Irving Reislcr, merchant, 2275 Decclles, Saint-Laurent.F'dward Samuel Berger, advocate, and Judith Lccker, secretary, wife of Kenneth Dollinger.the latter two of 1010 St.Catherine West.Montreal, for the following purposes: To deal in all types of ladies' and men's apparel, lingerie and sportswear, under the name of \"Rcxlcy's (1970) Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of SI each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 lx siège social de la compagnie est ù Montreal, district judiciaire de Montréal, /.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.31173 ' 5563-1969 Roulottes Montcalm ltée Montcalm Mobile Homes Ltd.1a: ministre des institutions financières, compagnies et cooi>érativcs donne avis, (m'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour île janvier 1970, constituant en corporation : Jcan-H.Massey, avocat, 338, Begin, Côme l'oulin, stagiaire, 15, Guy, et Doris Bolgcr, secrétaire, fille majeure, 261, Frechette, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce dc roulottes de voyage et dc toutes autres sortes dc maisons mobiles et remorques, sous lc nom de « Roulottes .Montcalm ltée \u2014 Montcalm Mobile Homes l.td.», avec un capital total de $140,000, divisé eu 400 actions ordinaires dc $100 chacune et en l.tlOO actions privilégiées dc $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.31173-0 198-1970 Roy, Bélunger & associés ltée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des comi>agnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de février 1970, constituant en corixiration : Lucien-F.Roy, 610, rue Tait, Saint-Laurent, Haymond-P.Bélanger, 289, rue Morrisson, Monl-ltoyul, tous «leux publicitaires, et J.Luwrcnce Foley, gérant, 80, Farnham, Beaconsficld, pour les objets suivants: Fuirc affaires comme entrepreneurs et conseillers en publicité, sous lc nom dc « Roy, Bélanger \\ associés liée », avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Le siège social dc lu compagnie est ù Montréal, district judiciaire dc Montréal./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 684-1970 Stc-Martinc Automobile inc.Ia: ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie dc la Loi des compagnies, il a uccordé des lettres patentes, en dote du 12c jour dc janvier 1970, constituant en corporation : licorges Dagenais, commerçant, 80, St-Charles, Philippe Fichault, 160, Ste-Catherinc, tous deux de Bcauharnois, et Normand Dagenais, 23, l'luce Allard, Sainte-Martine, ces deux derniers agents vendeurs, pour les objets suivants: Fuirc uffaircs comme garagistes et fuire le commerce d'automobiles, leurs parties et accessoires, sous le nom de « Ste-Martine Automobile inc.», avec un capital total dc $99,000, divisé en !H) actions ordinaires de $100 chacune et en 900 actions privilégiées de $100 chacune.2403 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 5563-1969 Roulottes Montcalm ltée Montcalm Mobile Homes Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies nnd Cooperatives, incorporating: Jcan-H.Massey, advocate, 338 Begin, Come Poulin, articles student, 15 Guy, and Doris Bolger, secretary, spinster of the full ugc of majority, 261 Frechette, nil three of Granby, for the following purposes: To manufacture und deal in trailers and in all other types of mobile homes, under the name of \"Roulottes Montcalm ltée \u2014 Montcalm Mobile Homes Ltd.\", with a total capital of $140,000, divided into 400 common shares of $100 each and 1,000 preferred shares of $100 each.The head office of the company is ot Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 198-1970 Roy, Bélanger & associés ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lucien-F.Roy, 610 Tait Street, Saint-Laurent, Ruymond-P.Bélanger, 2S9 Morrisson Street, Mount Royal, both publicists, and J.Lawrence Foley, manager, SO F'urnhum, Bcaconsficld, for the following purposes: To curry on business as advertising counsellors and contractors, under the name of \"Roy, Bélanger & associés ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.I.s-1'iiii.ii'i'i; Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 684-1970 Ste-Martine Automobile inc.Notice is given that under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Dagenais, trader, 80 St-Cliarles, Philippe Fichault, 160 Ste-Catherine, both of Bcauharnois, and Normand Dagenais, 23 Place Allard, Sainte-Martine, the latter two sales agents, for the following purposes: To carry on business as garage-keepers and to deal in automobiles, their parts and accessories, under the name of \"Stc-Martinc Automobile inc.\", with a total capital stock of $99,000, divided into 90 common shares of $100 each and into 900 preferred shares of $100 each. 24G4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' aimée, n\" 17 Le siège social i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Frank Spingola senior, Joseph Spingola, Frank Spingola junior, tous trois de 185, Rang St-Dominique, et Alex Spingola, 8180, St-Mau-rice, app.6, tous quatre cultivateurs, dc Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits agricoles et de produits alimentaires ainsi que leurs sous-produits, sous le nom de « Frank Spingola et fils ltée \u2014 Frank Spingola & Sons Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 100 actions ordinaires de $1 chacune, 39,797 actions privilégiées classe i A » de $1 chacune et en 103 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune Frank Spingola et fils ltée Frank Spingola & Sons Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Frank Spingola.senior, Joseph Spingola, Frank Spingola, junior, all three of 185 St-Dominique Range, and Alex Spingola, 8180 St-Maurice, Apt.6, ull four farmers of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To deal in agricultural an«l food products and by-products, under the name of \"Frank Spingola et fils ltée \u2014Frank Spingola & Sons Ltd.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 100 common shares of $1 each, 39,797 class \"A\" preferred shares of $1 each and 103 class \"B\" preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 lx siège social de la compagnie est 185, Rang St-Dominique, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34178* 52-1970 The Sutton Home Inc.Lc Foyer de Sutton inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2Se jour dc janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Reginald Stccves, llii|xTt Phelps, John Donner, tous trois retraités, Patricia Schoales, infirmière licenciée, épouse de John Westover, Edward Vogcl, cultivateur, Normand Goyette, propriétaire de garage, Kenneth Thomson, pasteur, tous de Sutton, et Arthur Corbcil, retraité, Abercorn, pour les objets suivants: Administrer un établissement de bien-être, sous lc nom de « The Sutton Home Inc.\u2014 Le Foyer de Sutton inc.».Le montant auquel doit se limiter la valeur îles biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de $500,000.Le siège social de la corporation est à Sutton, district judiciaire dc Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippk Bouchard.34173 0209-1969 Sydmais Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des com|>agiiies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Aliel Sclick, 1605, Norway, Mont-Royal, Joel A.Pinsky, 69, Downshire, Hampstead, et Martin Cross, 1105, Ridgewood Drive, Laval, tous trois avocats, |)our les objets suivants: Établir et diriger une compagnie dc placement, sous lc nom dc « Sydmais Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 39,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.\u202214173 206-1970 T.S.D.construction ltée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé îles lettres patentes, en date du 21e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Léo Sala m rin, 1453, Roosevelt, Laflèche, Paul Dulac, 605, Springfield, Greenfield Park, tous deux constructeurs, et Lionel Tourigny, agent-vendeur, 5600, Gérard, Saint-Hubert, pour les objets suivants: Faire affaires comme constructeurs et entrepreneurs généraux en construction et faire lc commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « T.S.D.construction ltée », avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.2467 The head office of the company is at 185 St-Dominique Range, Saint-Hyacinthe, judicial district of Saint-Hyacinthe.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 52-1970 The Sutton Home Inc.Le Foyer dc Sutton inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Reginald Steeves, Rupert Phelps, John Dormer, all three retired, Patricia Schoales, registered nurse, wife of John Westover, Edward Vogel, farmer, Normand Goyette, garage proprietor, Kenneth Thomson, clergyman, all of Sutton, and Arthur Corbcil, retired, Abercorn, for the following purposes: To administer a welfare institution, under the name of \"The Sutton Home Inc.\u2014 Le Foyer de Sutton inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may own or possess is to be limited, is $500,000.The head office of the corporation is at Sutton, judicial district of Bedford.Lb-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 6209-1969 Sydmais Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Abel Selick, 1605 Norway, Mount Royal, Joel A.Pinsky, 69 Downshire, Hampstead, and Martin Gross, 1105 Ridgewood Drive, Laval, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Sydmais Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $1 each and 39,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 206-1970 T.S.D.construction ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, incorporating: Léo Sabourin, 1453 Roosevelt, Laflèche, Paul Dulac, 605 Springfield, Greenfield Park, both builders, and Lionel Tourigny, sales agent, 5600 Gérard, Saint-Hubert, for the following purposes: To carry on business as builders and general building contractors, and to deal in all kinds of materials, under the name of \"T.S.D.construction ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. 2468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n° 17 Ix siège social de la compagnie est 3896, Mance, Laflèche, district judiciaire dc Montréal, /.c mus-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-d 216-1970 Tabagie Horizon inc.Lc ministre des institutions flnancièrcs, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première i>artic de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Donat Roy, courtier, Marie-Paulc Guay, ménagère, épouse dudit Donat Roy, et André Roy, industriel, tous trois dc 2524, Bicncourt, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Exploiter une tabagie, sous le nom de « Tabagie Horizon inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.I.c siège social dc la compagnie est 2520, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 0155-1909 I .ihah Import Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 26c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Louis Laportc, avocat, 3, St-Charlcs sud, Hermine Asselin, ménagère, fille majeure, 323, boulevard Manseau, et Lise Poirier, secrétaire, épouse d'André Asselin, 426, Beaudry, tous trois dc Joliette, pour les objets suivants: Fabriquer et faire lc commerce dc toutes sortes de chaussures et articles en cuir et leurs accessoires, sous le nom de < Tabah Import Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est à Joliette, district judiciaire dc Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 496-1970 Telindex inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de février 1970, constituant en corporation: Gilles-A.Denis, avocat, 4854, Côte des Neiges, Jcanninc Ouellcttc, 10200, Bois de Boulogne, et Cécile Morency, 8001, St-Hubert, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, tous trois dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc publicité et «l'édition, sous le nom de « Telindex inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 uctions ordinaires dc $10 chacune et en 2,000 uctions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 529-1970 The head office of the company is at 3896 Mance, Laflèche, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 216-19711 Tabagie Horizon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Donat Roy.broker, Maric-Paule Guay, housewife, wife of said Donat Roy, and André Roy, industrialist, all three of 2524 Biencourt, Saintc-Foy, for the following purposes: To operate a tobucco shop, under the name of « Tabagie Horizon inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 2520 Ste-Foy Road, Sainte-Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 6155-19G9 Tabab Import Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis Laportc, advocate, 3 St-Charlcs South, Hermine Asselin, housewife, spinster of the full age of majority.323 Manseau Boulevard, and Lise Poirier, secretary, wife of André Asselin, 426 Beaudry, all three of Joliette, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of shoes and leather goods and their accessories, under the name of \"Tabah Import Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of $100 each.The head office of the company is at Joliette.judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 490-197H Telindex inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles-A.Denis, advocate, 4854 Côte des Neiges, Jcanninc Ouellcttc, 10200 Bois de Boulogne, and Cécile Morency, 8001 St-Hubert, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as an advertising and publishing company, under the name of \"Telindex inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliees.34173 529-197' I QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 86, 1070, Vol.108, No.17 2469 Thcrmatrol of Canada Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1970, constituant en corporation : (icrald McCarthy, avocat, 4, Place Ville-Marie, Inircau 514, Céline Trudeau, 2132, rue Bossuet, lous deux de Montréal, et Valerie Jean Higgins, 50, avenue Hudson, Mont-Royal, ces deux dernières secrétaires, célibataires, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Thcrmatrol of Canada Ltd.», avec un capital divisé en 5,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est 4, Place Ville-Marie, bureau 514, Montréal, district judiciaire de Montréal.l.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173 311-1970 Tournée inc.1a; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Bernard Faribault, 175, boulevard Dcguirc, app.1415, Saint-Laurent, J.-Édouard Labelle, 100, ( îaspé, app.711, Verdun, Allan Lutfy, 1780, boulevard Laird, Mont-Royal, tous trois avocats, Patrick Kenniff, 5947, Decclles, app.5, Montréal, et André Laurin, 75, Glengarry, Mont-Royal, ces deux derniers étudiants, pour les objets suivants: Développer par tous les moyens disponibles une plus grande connaissance du Québec, du Canada et des autres pays, sous lc nom de « Tourbec inc.».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $500,000.Le siège social dc la corporation est 112, rue St-Paul ouest, Montréal, district judiciaire dc Montréal.l.e sous-ministre des institut ions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 106-1970 Tractions-mobiles Lcvcsque inc.Ix; ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour dc janvier 1970, constituant en corporation: Gilles Lévesquc, électricien, Louise L.Lévesquc, maîtresse de maison, épouse dudit Gilles Lévesquc, et Claude Bélanger, commis, tous trois de Saint-Alexandre, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de certains accessoires pour autos-neige ou autres véhicules motorisés, sous lc nom dc « Tractions-mobiles Lévesquc inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $5 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Lc siège social de la compagnie est à- Saint-Alexandre, district judiciaire dc Knmouraska.I.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 135-1970 Thermatrol of Canada Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gerald McCarthy, advocate, 4 Place Ville Marie, Suite 514, Céline Trudeau, 2132 Bossuet Street, both of Montreal, and Valerie Jean Higgins, 50 Hudson Avenue, Mount Royal, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To manufacture and deal in goods, wares and merchandise, under the name of \"Thermatrol of Canada Ltd.\", with a capital stock divided into 5,000,000 common shares without par value The head office of the company is at 4 Place Ville Marie, Suite 514, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Dcpul Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-o 311-1970 Tourbec inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Bernard Faribault, 175 Dcguire Blvd., Apt.1415, Saint-Laurent, J.-Édouard Labclle, 100 Gaspé, Apt.711, Verdun, Allan Lutfy, 1780 Laird Blvd., Mount Royal, all three advocates, Patrick Kenniff, 5947 Decelles, Apt.5, Montreal, ami André Laurin, 75 Glengarry, Mount Royal, the latter two students, for the following purposes: To foster, by all available means, a greater knowledge of Québec, Canada and other countries, under the name of \"Tourbec inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may acquire and hold is to he limited, is $500,000.The head office of the corporation is at 112 St-Paul St.west, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 106-1970 Trnctions-mobiles Lévesquc inc.Notice is hereby given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Ix-vcsquc, electrician, Louise L.Ix;vcsque, housewife, wife of the said Gilles Lévesquc, and Claude Bélanger, clerk, all three of Saint-Alexandre, for the following purposes: To manufacture and deal in certain accessories for snow-mobiles or other motor vehicles, under the name of \"Tractions-mobiles Lévesquc inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $5 each and 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Sainl-Alexandrc, judicial district of Kamouraska.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 135-1970 2470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1970, 102' année, n\" 17 Transilvania Credit House Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de janvier 1970, constituant en corporation: Stanley Cytrynbaum, 234, Sheraton Drive, Montréal-Ouest, Morton Bell, 701, Bertrand, Saint-Laurent, et Stephen Harper, 1212 ouest, des Pins, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger un grand magasin, sous le nom de «Transilvania Credit House Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 530-1970 T-Vcno inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de janvier 1970, constituant en corporation: Pierre Bourque, 48, Chartres, Dollard-des-Ormeaux, Claude Benoit, 1758, Jacques Lemais-tre, Michel Lespérance, 12227, de Poutrincourt, tous trois avocats, Jean Marsolais, 447, Querlies, et Denis St-Onge, 6597, Chambord, ces deux derniers étudiants, ces quatre derniers de Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tous produits, articles, objets ou marchandises, sous le nom de « T-Veno inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 3,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 4613, Montée des Sources, suite 1, Dollard-des-Or-meaux, district judiciaire de Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 328-1970 Variétés R.Labrosse inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1970, constituant en corporation : Réal LaBrosse, mécanicien, Dorothé Monaham, ménagère, épouse dm lit Réal LaBrosse, tous deux de 7809, St-Dominiquc, et Pierre-Paul Doré, plombier, 7805, St-Dominique, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire lc commerce de jouets, nouveautés, ameublements, quincaillerie, du bois et dc toutes sortes de spécialités connexes, sous le nom de « Variétés R.Labrosse inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Ix sous-ministre des institutions financières, compagnie et coopérative Ls-Piiilippe Bouchard.34173-0 344-1970 Transilvania Credit House Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Stanley Cytrynbaum, 234 Sheraton Drive, Montreal West, Morton Bell, 701 Bertrand, Saint-Laurent, ami Stephen Harper, 1212 Pine West, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a departmental store, under the name of \"Transilvania Credit House Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.34173-0 530-1970 T-Vcno inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Bourque, 48 Chartres, Dollard-des-Ormeaux, Claude Benoit, 1758 Jacques Lemaistre, Michel Lespérance, 12227 de Poutrincourt, all three advocates, .lean Marsolais, 447 Qucrbes, and Denis St-Onge.6597 Chambord, the latter two students, the latter four of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all products, articles, wares or merchandise, under the name of \"T-Veno inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is ut 4013 Montée des Sources, Suite 1, Dollard-dcs-Or-meaux, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéralires.Mm 328-1970 Variétés R.Labrosse inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1970.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Réal LaBrosse, mechanic, Dorothée Monaham, housewife, wife of said Real LaBrosse, both of 780!' St-Dominique, and Pierre-Paul Doré, plumber.7805 St-Dominique, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in toys, novelties, furniture, hardware, wood and of all kinds of related specialties, under the name of \"Variétés R.Labrosse inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cmpcrativcs MlTd 344-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2471 Venture Capital Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en daté du 2e jour de février 1970, constituant en corporation : Nathum Gelbcr, 171, chemin Edgehill, Westmount, David Katznelson, 5526, avenue Ashdale, Côte Saint-Luc, Arthur Bronstcin, 1100, avenue .McGregor, Montreal, et Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie dc placement et de portefeuille, sous le nom de « Venture Capital Corporation », avec un capital total dc 8300,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 290,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.Lc siège social de la compagnie est 1, Place Ville Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 484-1970 Venture Capital Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nahum Gelber, 171 Edgehill Road, Westmount, David Katznelson 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, Arthur Bronstcin, 1100 McGregor Avenue, Montreal, and Robert Litvack, 890 Stanstead Avenue, Mount Royal, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment and holding company, under the name of \"Venture Capital Corporation\", with a total capital stock of 8300,000, divided into 10,000 common shares of the par value of 81 each and 290,000 preferred shares of the par value of 81 each.The head office of the company is at 1 Place Ville Marie, suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 484-1970 Vogue Knitting Mills Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de janvier 1970, constituant en corporation: David Katznelson, 5526, avenue Ashdale, Côte Saint-Luc, Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, Sandor Klein, 6300, avenue Lennox, tous (Jeux de Montréal, et Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Manufacturer des vêtements de tricot, textiles, produits textiles, et sous-produits de toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Vogue Knitting Mills Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune, 10,000 actions privilégiées catégorie « A » d'une valeur au pairde 81 chacune et 20,000 actions privilégiées catégorie * B » d'une valeur au pair dc SI chacune.Lc siège social dc la compagnie est 5265, dc Gaspé, Montréal, district judiciaire de Montréal.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173 82-1970 Vogue Knitting Mills Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Katznelson, 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, Sandor Klein, 6300 Lennox Avenue, both of Montreal, and Robert Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, all four advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in knitwear, textiles, textile products and by-products of all kinds, under the name of \"Vogue Knitting Mills Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each, 10,000 class \"A\" preferred shares of a par value of SI each and 20,000 class \"B\" preferred shares of a par value of 81 each.The head office of the company is at 5265 De (Jaspé, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173-0 82-1970 Wick ha m Industries Inc.Les Industries Wickham inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de février 1970, constituant en corporation : Raymond Clair, 889, St-Gcorges, Roger Biais, 173d, Lowring, tous deux avocats, et Lucille Desmarais, secrétaire, épouse de Lucien Allie, 1375, Mayrand, tous trois dc Drummondville, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de produits, articles et marchandises dc toutes sortes, sous le nom de « Wickham Industries Inc.\u2014 Les Industries Wickham inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 15,000 actions privilégiées dc S10 chacune Wickham Industries Inc.Les Industries Wickham inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of February, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Clair, 889 St-Georges, Roger Biais, 173d Lowring, both advocates, and Lucille Desmarais, secretary, wife of Lucien Allie, 1375 Mayrand, idl three of Drummondville, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and goods, under the name of \"Wickham Industries Inc.\u2014 Les Industries Wickham inc.\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 5,000 common shares of 810 each and 15,000 preferred shares of S10 each. 2472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Le siège social de la compagnie est à Wickham, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34173-0 719-1970 The head office of the company is at Wickhnm, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34173 719-1970 Compagnies dissoutes Companies Dissolved Auberge du Portage inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Auberge du Portage inc.», constituée en corporation le 3 mai 1968, ù compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 1388-68 The Betty Spcirs-Pctcr Miller Dance Studios Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte dc « The Betty Speirs-Peter Miller Dance Studios Ltd.», constituée en corporation le 21 novembre 1947, à compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 6885-47 Cedar Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Cedar Corporation », constituée en corporation lc 11 janvier 1952, i\\ compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 14489-51 The Dyno Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon .de charte de « The Dyno Corporation », constituée en corporation le 25 juillet 1966, à compter du 15 avril 1970.Iœ directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 3083-66 Les Entreprises Robert inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de «Les Entreprises Robert inc.», constituée en corporation le 13 avril 1949, à compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 3734-49 Florès inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon Auberge du Portage inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Auberge du Portage inc.\", incorporated on May 3, 196k, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 1388-OS The Betty Spcirs-Pctcr Miller Dance Studios Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"The Betty Speirs-Pcter Miller Dance Studios Ltd.\", incorporated on November 21, 1947, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 6885-47 Cedar Corporation Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has lieen pleased to accept the surrender of the charter of \"Cedar Corporation\", incorporated on January 11, 1952.on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 14489-51 The Dyno Corporation Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Com panics and Cooperatives has been pleased li> accept the surrender of the charter of \"The Dyno Corporation\", incorporated on July 25, 1966, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 3083-liO Les Entreprises Robert inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Les Entreprises Robert inc.\", incorporated on April 13, 1940.on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 3734-49 Flores inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2473 de charte de « Flores inc.», constituée en corpora-lion le 2 mai 1967, à compter du 15 avril 1970.7,e directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 1966-67 Lutfy Realties Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Lufty Realties Ltd.», constituée en corporation le 1er juin 1944, à compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-o 3143-44 M.& S.Publications ltée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte dc «M.& S.Publications ltée », constituée en corporation lc 23 décembre 1966, à compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-0 5317-66 .Mack 1oration le 27 septembre 1945, il compter du 15 avril 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-o 6101-45 The Transit Dry Kiln Lumber Company Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « The Transit Dry Kiln Lumber Company Limited », constituée en corporation le 8 juillet 1946, à compter du 27 février 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.34173-o 5254-40 accept the surrender of the charter of \"Florès inc.\", incorporated on May 2, 1967, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of Ike Companies Branch.34173 1966-67 Lufly Realties Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Lutfy Realties Ltd.\", incorporated on June 1, 1944, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 3143-44 M.& S.Publications ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"M.& S.Publications ltée\", incorporated on December 23, 1966, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 5317-66 Mackle Commercial Centre Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has l>een pleased to accept the surrender of the charter of \"Mackle Commercial Centre Inc.\", incorporated on May 25, 1961, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 12575-61 Pinnacle Investment Corp.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Pinnacle Investment Corp.\", incorporated on April 9,1957, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 10835-57 Servitor Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"Servitor Inc.\", incorporated on September 27, 1945, on and from April 15, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 6101-45 The Transit Dry Kiln Lumber Company Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender of the charter of \"The Transit Dry Kiln Lumber Company Limited\", incorporated on July 8, 1946, on and from February 27, 1970.Rocii Rioux, Director of the Companies Branch.34173 5254-46 2474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 86 avril 1970, 108' année, n° 17 Ministère des Terres et Forêts Department of Lands and Forests Cadastre Cadastre Paroisse de Charlesbourg Cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, municipalité de la cité de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 279-2-72-1, 279-2-73-3 et 279-3-35 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 mars 1970.Le sous-ministre, 34193-0 Fernand Boutin.Canton Joly Cadastre officiel du canton Joly, municipalité du canton Joly, division d'enregistrement de La-belle.Avis est par la présente donné que le lot 42 est ajouté et que les lots 16B, 16D, 16-B-l, 16-B-2 et 16-B-3 du rang G sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 février 1970.Le sous-ministre, 34193-0 Fernand Boutin.Cité dc Montréal, Quartier Stc-Annc Cadastre officiel de la cité de Montréal, quartier Ste-Anne, municipalité de la ville de Montréal, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 1920 et 1921 sont ajoutés et que les lots 291, 292, 293 et qu'une partie des lots 290 et 294 sont annulés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 25 février 1970.Le sous-ministre, 34193-o Fernand Boutin.Paroisse de Notre-Dame dc la Victoire Cadastre officiel de Ja paroisse dc Notre-Dame de la Victoire, municipalité de la ville de Lévis, quartier Déziel, division d'enregistrement dc Lévis.Avis est par la présente donné que le lot 99-4 est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 mars 1970.Le sous-ministre, 34193-o Fernand Boutin.Canton Rawdon Cadastre officiel du canton Rawdon, municipalité du canton Rawdon, division d'enregistrement dc Montcalm.Avis est par la présente donné que le lot 9b-1 du rang V est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 23 février 1970.Le sous-ministre, 34193-o Fernand Boutin.Paroisse de Si-Antoine de Longueuil Cadastre officiel de la paroisse de St-Antoinc de Longueuil, municipalité de la ville dc Longueuil, division d'enregistrement de Chambly.Parish of Charlesbourg Official cadastre of the parish of Charlesbourg, municipality of the city of Charlesbourg, registration division of Québec.Notice is hereby given that lots 279-2-72-1, 279-2-73-3 and 279-3-35 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, March 24, 1970.Fernand Boutin, 34193-o Deputy Minister.Township Joly.Official cadastre of township Joly, municipality of township Joly, registration division of La-belle.Notice is hereby given that lot 42 is added ami that lots 16B, 16D, 16-B-l, 16-B-2 and 16-B-3, range G arc cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 25, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.City of Montreal, Stc-Annc Ward Official cadastre of the city of Montreal, Sle-Anne Ward, municipality of the town of Montreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 1920 and 1921 are added and that lots 291,292, 293 and a pari of lots 290 and 294 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 25, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.Parish of Notre-Dame de la Victoire Official cadastre of the parish of Notre-Dame dc la Victoire, municipality of the town of Levis, Déziel Ward, registration division of Levi.-.Notice is hereby given that lot 99-4 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, March 16, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.Township Rawdon Official cadastre of township Rawdon, municipality of township Rawdon, registration division of Montcalm.Notice is hereby given that lot 9b-1, range V is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 23, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.Parish of St-Aiitoinc dc Longueuil Official cadastre of the parish of St-Antoinc de Longueuil, municipality of the town of Longueuil, registration division of Chambly. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2475 Avis est par la présente donné que les lots (19-67, 69-106, 69-207 à 69-210, 69-268, 69-329, 69-360, 69-421, 69-482, 69-513, 69-574, 69-635, 09-666, 69-727, 69-767, 69-776 à 69-779, 69-789, (19-818, 69-859, 69-882A, 69-902, 69-903, 69-905 à 69-911, 69-929 à 69-937, 69-961 à 69-965, 09-967, 69-981, 69-991 à 69-996 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 24 mars 1970.Le sous-ministre, 34193-o Fernand Boutin.Paroisse de Ste-Cceile Cadastre officiel dc la paroisse dc Ste-Cécile, municipalité dc la cité de Salaberry de Vallcy-field, division d'enregistrement de Bcauharnois.Avis est par la présente donné «pie les lots 93-22 à 93-24, 93-58 à 93-60, 93-62 ù 93-65, 93-97 à 93-100, 93-102 à 93-106, 94-18, 94-21 à 94-24 et une partie du lot 93-20 et une partie des lots 93-61 (rue Dion) et 93-101 (rue Narcisse) sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, lc 1er avril 1970.Ije sous-ministre, 34193-0 Fernand Boutin.Paroisse dc Stc-Foyc Cadastre officiel de la paroisse dc Stc-Foyc, municipalité de la ville dc Stc-Foy, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que le lot 451 est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 avril 1970.Le sous-ministre, 34193-0 Fernand Boutin.Assemblée La Compagnie du chemin dc fer Aima & Jonquières Les actionnaires de « La Compagnie du chemin dc fer Aima & Jonquières » sont convoqués en assemblée générale annuelle lc mardi, vingt-huit avril 1970, à trois heures de l'après-midi, au numéro 1, de l'immeuble Place Ville-Marie, à Montréal, pour recevoir les comptes de l'exercice 1969, procéder à l'élection des administrateurs et à la nomination des vérificateurs pour lc prochain terme d'office et pour délibérer sur toute autre question du ressort de l'assemblée Le secrétaire, 34106-16-2-o J.R.Turgeox.Notice is hereby given that lots 69-67, 69-106, 69-207 to 69-210, 69-268, 69-329, 69-360, 69-421, 69-482, 69-513, 69-574, 69-635, 69-666, 69-727, 69-767, 69-776 to 69-779, 69-789, 69-818, 69-859, 69-882A, 69-902, 69-903, 69-905 to 69-911, 69-929 to 69-937, 69-961 to 69-965, 69-967, 69-981, 69-991 to 69-996 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, March 24, 1970.Fernand Boutin, 34I93-o Deputy Minister.Parish of Ste-Cécile Official cadastre of the parish of Ste-Cécile, municipality of the city of Salaberry dc Valley-field, registration division of Beauharnois.Notice is hereby given that lots 93-22 to 93-24, 93-58 to 93-60, 93-62 to 93-65, 93-97 to 93-100, 93-102 to 93-106, 94-18, 94-21 to 94-24 and a part of lots 93-20 and a part of lot 93-61 (rue Dion) and 93-101 (rue Narcisse) are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, April 1, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.Parish of Ste-Foyc Official cadastre of the parish of Ste-Foyc, municipality of the town of Ste-Foy, registration division of Québec.Notice is hereby given that lot 451 is added in virtue of Article 2174A of the Civil Code Québec, April 0, 1970.Fernand Boutin, 34193-0 Deputy Minister.Meeting The Alma & Jonquières Railway Company The Annual Meeting of the Shareholders of \"The Alma & Jonquières Railway Company\" to receive the 1969 financial statements of the company, to elect directors and appoint auditors for the ensuing year, and to transact such other business as may properly come before the meeting, will be held in the 31st floor board room, 1, Place Ville Marie, Montreal, on Tuesday, 28 April 1970, at three o'clock in the afternoon.J.R.Turgeon, 34106-16-2-o Secretary.Association coopérative Cooperative Association Association coopérative immobilière dc Maria (Loi des associations coopératives) Avis est donné que l'association coopérative « Association coopérative immobilière de Maria», dont le siège social était situé à Marin, dans le district électoral de Bonaventure, a été dissoute le 10 février 1970, et ce conformément aux dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 34197-0 Ls-Philippe Bouchard.Association coopérative immobilière de Maria (Cooperative Associations Act) Notice is given that the cooperative association \"Association coopérative immobilière de Maria\", the head office of which was situated at Maria, in the electoral district of Bonaventure, was dissolved on February 10, 1970, and such, pursuant to the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-up Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.34197 Companies and Cooperatives. 2476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Demandes à la Législature Trust Général du Canada et Société d'Administration et dc Fiducie Avis est, par les présentes, donné que lc « Trust (¦énéral du Canada » et la « Société d'Administration et de Fiducie » s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec, à sa prochaine session, pour obtenir la passation d'une loi les fusionnant en une seule nouvelle compagnie et accordant et définissant les pouvoirs et les droits de ladite nouvelle compagnie.Montréal, ce 3e jour d'avril 1970.Les procureurs des requérantes, Honorable Edouard Asselin, en.Mes Blain, Piché, Bergeron, Goddout, 34026-15-4-o Emery, Blain & Vallerand.L'Association des comptables généraux licenciés de la province dc Québec Avis est donné que < L'Association des comptables généraux licenciés dc la province de Québec » s'adressera à l'assemblée nationale du Québec, à la prochaine session, pour demander l'adoption d'une loi abrogeant la Loi des comptables généraux licenciés du Québec, 10, George VI, chapitre 89, et la remplaçant par une nouvelle loi aux fins suivantes: 1° Lui permettre dc continuer son existence sous le nom de « Corporation des comptables généraux licenciés du Québec » en français et dc « Corporation of Certified General Accountants of Québec » en anglais; 2° Préciser les buts, la nature des travaux, les conditions d'admission à l'étude, à l'exercice dc la profession et les règles dc discipline de l'Association des comptables généraux licenciés du Québec; 3° Regrouper toutes les lois permettant aux comptables généraux licenciés du Québec d'agir comme vérificateurs.Québec, le 27 février 1970.Les procureurs de la requérante.Mes Severin Lachapelle 34087-16-4-o et Jacques Marquis.Séminaire St-Gcrmain dc Rimouski Avis est, par les présentes, donné que le « Séminaire de St-Germain de Rimouski > s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa prochaine session pour obtenir des amendements H sa charte (34 Victoria chapitre 47) aux fins suivantes: a) pourvoir au remplacement des membres dc la corporation; 6) la libérer des restrictions à l'exercice dc ses droits contenues dans sa charte; c) augmenter la valeur annuelle des immeubles qu'elle peut posséder; i des Cours municipales (Statuts refondus 1964, chapitre 24) le lieutenant-gouverneur en conseil a donné son approbation ù ces règlements.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1118, dated March 18, 1970, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order that a proclamation be issued: (a) to announce the deposit of the said revised plan and book of reference of that part of the cadastre of the parish of Saint-François, situated in the registration division of Bcauce; (b) to fix the date of publication of the aforementioned proclamation as the day on which paragraph 1-C, section 3, chapter 104 of the Statutes of 1930-31 shall come into force with respect to the said revised purt of the said cadastre; (c) to invite all interested parties, under pain of losing the priority conferred by law, to renew, within the year iollowing the above-fixed date, all hypothecs particularly affecting any of the lots on the plan and in the book of reference, and not including hypothecs affecting all the subdivided land.Ol all of which, all Our loving subjects and all others whom these presents may concern, are hereby required to take notice, and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved, the Honourable Hugues Lapointe, p.c., q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our city of Québec, in Our Province of Québec, this eighteenth day of March, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy, and in the nineteenth year of Our Reign.By command, Lucien Darveau, 34226 Assistant Deputy Attorney General.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Quél>cc, [L.S.1 ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas the municipal council of the village of Saint-Jcan-dc-Boischatc), county of Montmorency No.1, submitted for approval its by-law number 81 for the purpose of submitting the territory of the said municipality to the jurisdiction of the Municipal Court of the town of Beauport; Whereas the municipal council of the town of Beauport, by its by-law number 522, agreed to the terms of the said by-law adopted by the municipal council of the village of Saint-.Ican-de-Boiscliatcl; Whereas, under section 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statutes, 1964, chapter 24), the Lieutenant-Governor in Council gave his approval to the said by-laws. 2492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102- année, n° 17 À ces causes, «le l'avis et du consentement dc Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 1533, en date du 1er avril 1970, et vu les dispositions des articles 693 à 697 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus 1964, chapitre 193), et des articles 3 à 7 de la Loi des Cours municipales (Statuts refondus 1964, chapitre 24), Nous avons décrété et décrétons qu'a compter dc trente et un jours après la publication de la présente proclamation dans la Gazelle officielle de Québec, le territoire de la municipalité de Saint-Jcan-dc-Boischatel sera soumis a la juridiction dc la Cour municipale dc la ville dc Beauport.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et dc se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur iccllcs apposer le grand sceau dc Notre province dc Québec: Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lai-ointe, cp., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville dc Québec, de Notre province dc Québec, ce premier jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-dix dc l'ère chrétienne et dc Notre Règne In dix-neuvième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, 34226-0 Lucien Darveau.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1533, and dated April 1, 1970, and in view of the provisions of sections 693 to 697 of the Cities an«l Towns Act (Revised Statutes, 1964, cliaptcr 193), and of sections 3 to 7 of the Municipal Courts Act (Revised Statutes.1964, chapter 24), We have decreed and ératives donne avis «pic le 20 avril 1970, il a autorisé le changement de nom dc « \\al fraternité des policiers dc Jacques-Cartier inc.», dont la constitution sous le nom originaire dc < L'association des policiers dc la cité «le Jacques-Cartier », a été autorisée le 12 février 1959, et «lont le siège social est situé à Longueuil, en celui de « La fraternité des policiers de Longueuil», et ce, en vertu dc lu Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Québec, le 20 avril 1970./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires, Ls-Philippe Bouchard.34257-u 520-5S Association professionnelle du personnel de direction et dc gestion de la fonction publique (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on April 13,1970, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association professionnelle du personnel dc direction et de gestion de la fonction publique\", with head office situated at 155 Charest Boulevard East, Québec 2, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34241 15-1970 La fraternité des policiers de Longueuil The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on April 20, 1970, he authorized the changé of ame of \"Ia fraternité des policiers de Jacques-Cartier inc.\", the incorporation of which under the original name of \"L'association des policiers dc la cité dc Jac«iucs-Cartier\" was authorized on February 12,1959, and the head office of which is situated at Longueuil, to that of \"La fraternité des policiers dc Longueuil\", and such, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, chapter 146.Québec, April 20, 1970.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.34257 520-58 Nominations Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, pur commissions sous le grand sceau «le lu province, les nominations suivantes: Québec, le 21 janvier 1970.M.Jules All,ml, avocat, dc Victoriavillc; coroner suppléant pour le district «l'Arthabasku, avec juridiction seulement sur le district électoral d'Arthabaska.Québec, le 11 février 1970.M.Fernand Bernurd, docteur en médecine, de Suint-Joseph, comté de Bcuticc: coroner suppléunt pour le district judiciaire «le Bcauce, avec juridiction plus s|>écialcmcnt sur le district électoral de Beaùce, à compter de lu date de son assermenta-tion.Québec, le 4 murs 1970.M.Bcrnanl Séguin, docteur en médecine, de Murdoch ville: coroner pour le district judiciaire «le Gaspé, avec juridiction plus spécialement sur Murdochvillc et les environs, sur la partie du district électoral dc Gnspé-Sud située au nord dc la rivière St-.lean, sur le canton Sydenham situé dans lc district électoral de Gaspé-Nord, et sur lu partie du canton Fox comprise dnns ce dernier district électoral, ù compter «le la date dc son ussermentation.M.Jean-Marc Arsenault, docteur en médecine, dc la ville de Gagnon : coroner pour lc district juili- \\ p| min i nu-nt s Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been plcuscd to make the following appointments, by commissions under the Great Seal of the Province: Québec, January 21, 1970.Mr.Jules Allard, advocate, of Victoriavillc: acting coroner for the district of Arthabaska, with jurisdiction only over the electoral district of Arthabaska.Québec, February 11, 1970.Mr.Fernand Bernard, Doctor of Médecine, of Saint-Joseph, county of Bcaucc: acting coroner for the judicial district of Bcaucc, with jurisdiction particularly over the electoral district of Bcauce, from and after the date of his swearing in.Québec, March 4, 1970.Mr.Bernard Séguin, D«wtor of Médecine, of Murdochvillc: coroner for the judicial district of Gaspé, with jurisdiction particularly over Murdochvillc and surrounding district, over that part of the electoral district of Gaspc-South situated north of the St-Jean River, over the township of Sydenham situated in the electoral district of Gaspc-North, and over that part of the township of Fox situated in the latter electoral district, from and after the date of his swearing in.Mr.Jean-Marc Arscnault, Doctor of Médecine, of the town of Gagnon: coroner for the judicial 2496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 ciaire de Hauterive, avec juridiction plus spécialement sur la ville dc Gagnon et ses environs.Québec, le 11 mars 1970.M.Gilles La Haye, avocat et membre du Barreau du Québec, de Québec: juge des Sessions, avec juridiction dans toute la province, mais tout particulièrement et sans restriction, dans le district judiciaire de Québec, avec résidence dans la ville de Québec ou le voisinage immédiat, ledit M.Gilles La Haye, vu sa présente nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil comme juge des Sessions, étant autorisé a exercer, sous l'autorité du paragraphe b) dc l'article 466 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI de ce Code criminel.Québec, le 21 avril 1970.Le sous-procureur général adjoint, 34226-0 Lucien Dakveau, ch.district of Hauterive, with jurisdiction particularly over the town of Gagnon and surrounding district.Québec, March II, 1970.Mr.Gilles La Haye, advocate and member of the Bar of Québec, of Québec: Judge of the Sessions, with jurisdiction over the entire Province, particularly and without restriction over the judicial district of Québec, with residence in the city of Québec or the immediate vicinity: the said Mr.Gilles La Haye, in view of his appointment by the Lieutenant-Governor in Council as Judge of the Sessions, is authorized to exercise, under paragraph (b) of section 400 of the Criminal Code, jurisdiction of a magistrate under Part XVI of the said Criminal Code.Quél>ec, April 21, 1970.Lucien Dauveau, q.c, 34220 Assistant Deputy Attorney General.Loi électorale du Québec A vis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « J.-P.Verret Publicité', 330, Saint-Roch, Québec, est reconnue comme mandataire dc monsieur Maurice Hamcl, agent officiel dc monsieur Fernand Boudreau, candidat du parti de l'Union Nationale dans le district électoral de Saint-Sauveur pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 avril 1970.Québec, lc 21 avril 1970.Le président général des élections, 34244-o François Drouin, c.r.Ix>i électorale du Québec An» concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence dc publicité « Pierre Tremblay Publicité», 877 est, boulevard Cliarest, Québec, est reconnue comme mandataire de monsieur Jacques-E.Fortier, agent officiel de monsieur Claude Castonguay, candidat du Parti libéral du Québec dans le district électoral de Louis-Hébert pour les présentes élections dont lc scrutin est fixé au 29 avril 1970.Québec, lc 21 avril 1970.Lc président général des élections, 34244-0 François Drouin, c.r.Québec Election Act Notice concerning a publicity agency (section 37?) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"J.-P.Verret Publicité\", 330, Saint-Roch, Québec, is recognized as the authorized agent of Mr.Maurice Hamel, official agent of Mr.Fernand Boudreau, Union National party candidate in the electoral district of Saint-Sauvcur for the present election, for which voting is fixed for April 29, 1970.Québec, April 21, 1970.François Drouin, q.c, 34244-0 Chief Retorning-Officer.Quéliec Election Act Notice concerning a publicity agency (section 37?) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Pierre Tremblay Publicité\", 877, Cliarest Boulevard East, Québec, is recognized as the authorized agent of Mr.Jacques-E.Portier, official agent of Mr.Claude Castonguay, Québec Liberal Party candidate in the electoral district of Louis-Hébert for the present election, for which voting is fixed for April 29, 1970.Québec, April 21, 1970.François Drouin, q.c, 34244-0 Chief Regurning-Officer.Loi électorale du Quéliec Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Pierre Tremblay Publicité», 877 est, boulevard Cliarest, Québec, est reconnue comme mandataire de monsieur Roland Durand, agent officiel de monsieur André Harvey, candidat du Parti libéral «lu Québec dans le district électoral de ( 'hanveau pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 avril 1970.Québec, lc 21 avril 1970.Le président général des élections, 23244-0 François Drouin, c.r.Québec Election Act Notice concerning a publicity agency (section 37?) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Pierre Tremblay Publicité\", 877, Cliarest Boulevard East, Québec, is recognized as the authorized agent of Mr.Roland Durant, official agent of Mr.André Harvey, Québec Liberal Party candidate in the electoral district of Chauveau for the present election, for which voting is fixed for April 29, 1970.Québec, April 21, 1970.François Drouin, q.c, 34244-o Chief Returning-Officer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2497 Loi électorale du Québec .1 rin concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité \"Pierre Tremblay Publicité\", 877 est, boulevard Cliarest, Québec, est reconnue comme mandataire de monsieur Raymond Roy, agent olticicl dc monsieur Jacques Durand, candidat du Parti libéral du Québec dans le district électoral de Dorchester pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 avril 1970.Quéliec, le 21 avril 1970.Le président général des élections, .'14244-0 François Drouin, en.Loi électorale du Québec Avis concernant une agence de publicité (article 377) Je donne avis, par les présentes, que l'agence de publicité « Inter-Canada Limitée », 1374 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, est reconnue comme mandataire dc monsieur Jacques Dcsjar-dins, agent olficicl de monsieur Gérard Beaudry, candidat du Parti libéral du Québec dans le district électoral de Bourget pour les présentes élections dont le scrutin est fixé au 29 avril 1970.Québec, le 21 avril 1970.Le président général des élections, 34244-0 François Drouin, ch.Québec Election Act Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Pierre Tremblay Publicité\", 877 Cliarest Boulevard East, Québec, is recognized as the authorized agent of Mr.Raymond Roy, official agent of Mr.Jacques Durand, Québec Liberal Party candidate in the electoral district of Dorchester for the present election, for which voting is fixed for April 29, 1970.Québec, April 21, 1970.François Drouin, q.c, 34244-o Chief Relurning-Officer.Québec Election Act Notice concerning a publicity agency (section 377) I give notice, by these presents, that the publicity agency \"Inter-Canada Limitée\", 1374, Sherbrooke Street West, Montreal, is recognized as the authorized agent of Mr.Jacques Desjar-dins, official agent of Mr.Gérard Beaudry, Québec Liberal Party candidate in the electoral district of Bourgct for the present election, for which voting is fixed for April 29, 1970.Québec, April 21, 1970.François Drouin, q.c, 34244-o Chief Relurning-Officer.Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies et Institutions, Companies and coopératives Cooperatives Assurances Insurance The Citadel Insurance Company of Canada Limited Avis d'annulation de permis el de certificat d'enregistrement Attendu que « The Citadel Insurance Company of Canada Limited», dont le siège social est situé à Toronto, province d'Ontario, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec « Sun Insurance Office Limited», dont le siège social est situé à Londres, Angleterre, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 1er avril 1970, et lequel contrat dc réassurance a pris effet le 1er janvier 1970; Attendu que « Sun Insurance Office Limited » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « The Citadel Insurance Company of Canada Limited » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de ln Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « The Citadel Insurance Company of Canada Limited » sont annulés à compter du 1er avril 1970.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 14 avril 1970.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopéralires de la province, Le surintendant des assurances, 34251-17-2-0 Rooer-A.Camaraire.The Citadel Insurance Company of Canada Limited Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"The Citadel Insurance Company of Canada Limited\", whose head office is situated in Toronto, Province of Ontario, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"Sun Insurance Office Limited\", whose head office is situated in London, England, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 1st of April 1970, with effect from the 1st of January 1970; Whereas \"Sun Insurance Office Limited\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"The Citadel Insurance Company of Canada Limited\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"The Citadel Insurance Company of Canada Limited\" are cancelled as from the 1st of April 1970.Given at the Office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 14th of April 1970.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 34251-17-2-o Superintendent of Insurance. 2498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Avis divers Succession dame Béatrice Meunier Filottc Avis est donné que M.Claude l'ilotte agissant personnellemeiit et comme procureur à ses frères cl.soeurs: Dame Jeanne l'ilotte épouse de Rémi Morissctte, Henri l'ilotte, Dumc Lucienne l'ilotte, é|x>usc de Benoit Mallette, Georges l'ilotte, Roger l'ilotte, Guy Pilotte, Fernand l'ilotte, Dame France Pilottc épouse de R.Philpott, Dame Simonne l'ilotte veuve dc Paul Alain et Lucien Pilotte, ont accepté sous bénificc d'inventaire la succession de leur mère Dame Béatrice Meunier veuve de Georges Pilotte, en son vivant domiciliée au numéro 246 dc la rue St-Thomas, ù Longueuil, et décédée le premier novembre mil neuf cent soixante-neuf, le tout tel qu'il appert de l'acte reçu par le notaire Mireille Lamarre, dc 59 rue dc l'Église, à Dorion, comté dc Vaudreuil, le 24 mars 1970 et enregistré il Longueuil le 3 avril 1970 sous le numéro 325890 au bureau d'enregistrement dc Chambly.Dorion, ce 7 avril 1070.Le procureur de Claude l'ilotte, 34230-o Si i ki:i i.i.i : Lamarre, notaire.Ville dc Asbestos Avis est par les présentes donné que, conformément à une résolution adoptée par son conseil municipal lors d'une assemblée tenue mercredi lc 7c jour dc janvier 1970, la ville d'Asbestos a l'intention dc se prévaloir dc l'article 430 de la Loi des cités et villes, statuts refondus du Québec 1964, chapitre 193, qui se lit comme suit: 430.Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins dix ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes: 1° Lc conseil approuve pur résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie dc celles-ci, pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article; 2° Cette description doit être faite d'après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi du cadastre (chap.320); 3° L'original de cette description doit être déposé au bureau du greffier de la municipalité et une copie certifiée par un ar|ientcur-géoniètre doit être déposée au bureau du registrateur de la division d'enregistrement où se trouvent les terrains visés; 4° Lc greffier dc la municipalité fait publier deux fois dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant dans la municipalité, avec un intervalle d'au moins trois mois et d'au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant: a) le texte intégral du présent article; 6) une description sommaire des rues ou ruelles concernées; c) une déclaration à l'effet que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds desdites rues ou ruelles est prescrit s'il n'est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l'année suivant la dernière publication dans la Gazette officielle du Québec.La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard de rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des dix années précédentes, S.R.1941, c.233, a.429a; 11-12 Eliz.II, c.45.a.11.Miscellaneous Notices Estate of Mrs.Béatrice Meunier l'ilotte Notice is given that Mr.Claude Pilotte acting personally ami as attorney for bis brothers ami sisters: Mrs.Jeanne Pilottc, wife of Rémi Morissctte, Henri l'ilotte, Mrs.Lucienne Pilotte, wife of Benoit Mallette, Georges l'ilotte, Roger l'ilotte, (îuy l'ilotte, Fernand l'ilotte, Mrs.France l'ilotte, wife of R.Philpott, Mrs.Simonne l'ilotte, widow of Paul Alain and Lucien l'ilotte, have accepted under licncfit of inventory the estate of their mother Mrs.Béatrice Meunier, widow of Georges l'ilotte, when living residing at 2-lti St Thomas Street, at Longueuil, and deceased on the first day of November, one thousand nine hundred ami sixty-nine, the whole as it appears on a deed received before the notary, Mireille Lamarre, of 50 de l'Église Street, at Dorion.County of Vaudreuil, on March 24, 1970, and registered at Longueuil on April 3, 1970, under number 325890 at the registry office of Chambly.Dorion, this April 7, 1970.Mireille Lamarre, Notary, 34230 Attorney for Claude Pilottc.Town of Asbestos Notice is hereby given that, by virtue of a resolution of its Municipal Council passed at a meeting duly held on Wednesday, the 7th day of January 1970, the town of Asbestos proposes to avail itself of section 430 of the Cities and Towns Act, 1964 Revised Statutes of Québec, chapter 193, which reads as follows: 430.The streets or lanes open to the public for ten years or more shall become the property of the municipality upon the observance of the following formalities: 1.The council shall approve by resolution a description of all streets or lanes or parts thereof with respect to which the municipality proposes to avail itself of this section; 2.Such description shall be made according to an official plan and book of reference made ami deposited in conformity with the Cadastre Act (chap.320); 3.The original of such description must be deposited in the office of the clerk of the municipality and a copy certified by a land surveyor shall be deposited in the office of the registrar of the registration division where the lands concerned arc situated; 4.The clerk of the municipality shall cause to be published twice in the Québec Official Gazette and in daily newspaper circulating in the municipality, with an interval of not less than three months nor more than four months between publications, a notice containing: (a) the full text of this section; (b) a summary description of the streets or lanes concrncd; (c) a declaration to the effect that the formalities prescribed by paragraphs 1 and 2 have been observed.Any right that third parties might claim to the ownership of the site of the said streets or lanes shall be prescribed unless exercised by suit before the competent court within one year after the last publication in the Québec Official Gazette.The municipality cannot avail itself of this section with respect to streets or lanes on which it has levied any tax within the preceding ten years.R.S.1941, c.233, s.429a; 11-12 Eliz.II.c.45.s.11. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2499 Description sommaire des rues et ruelles \u2014 Summary description of Streets and Avenues Nom Name Hue Deshaies Street.4e Avenue 4th.3c Avenue 3rd.2c Avenue 2nd.1ère Avenue 1st.1ère Avenue 1st.2c Avenue 2nd.3c Avenue 3rd.4c Avenue 4th.Rue Bourbcau Street.Rue Bourbeau Street.Rue Panneton Street.Rue St-Jacques Street.Boulevard Olivier Boulevard.Rue Chassé Street.Rue St-Dominique Street Hue St-Roch Street.Boulevard Olivier Boulevard.Rue St-Roch Street.Rue St-Jacques Street.Rue St-Roch Street.Rue Belvédère Street.Boulevard St-LAic Boulevard.Rue Bourbcau Street.Boulevard St-Luc Boulevard.Rue St-Hubcrt Street.Rue St-Edmond Street.Boulevard St-Luc Boulevard.Rue St-Charles Street.Rue St-Edmond Street.Rue St-Edmond Street.Rue Du Pouvoir Street.Rue Albert Street.Rue Belvédère Street.Avenue Manville Avenue Rue Albert Street.Rue Albert Street.Rue Albert Street.Rue Albert Street.Rue Albert Street.Rue Albert Street.Boulevard St-Luc Boulevard.Boulevard St-Luc Boulevard.Rue Doyon Street.Rue Lavigne Street.Rue St-Philippc Street.Rue St-Philippe Street.Rue St-Philippc Street.Rue St-Philippe Street.Rue Street.Avenue Manville Ouest West Manville Avenue.Avenue Manville Ouest West Manville Avenue.Lot No Lot No.1-41.\tn 1-45.\tn 1-49.\tn 1-53.\tn 1-57.\tu 1-63.\tn 1-72.\tn 1-81.\tù 1-90.\tn 6-4.\tin.6-62.\tin.6-64.\tin.6E-132.\tin.7A-29.\tn 7A-234.\tn 7D-19.\tm.7D-25,\tin.7E-80.\tin.7E-90.\tnr.7E-194.\tm.7E-195,\tm.10A-19.\tii 24-65.\tn.26-5.\tn 26-22-1.\tn 26-74.\tn 26-75.\tn 26-76.\tn 26-77.\tn 26-101\tn .3-156.\tn 80-192.\tn P.118-8.\tii P.118-20.\tn .P.118-73.\tii 121-1.\tn 122-1.\tii 123-1.\tii 124-1.\tii 126-1.\tn 127-1.\tn 7E-86.\tnr.7E-93.,\tm.11D-23.\tra.11D-49.\thi.11D-79.\tin.11D-143.\tin.11D-151____\tm.11D-282-\tm.11D-274-\tm.29.\tm.30.\tnr.Rang Range Cadastre Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Village Asbestos.Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Canton Shipton Township Superficie (m.a.) Area (E.m.) p.c.-sq 58,080.5,940.5,940.5,940.36,026.22,011.30,096.32,115.34,280.11,013.6,700.10,660.4,000.69,600.6,187.7.8,868.365.16,909.2.18,284.20,100.18,860.26,360.13,200.9,440.5,940.29,304.30,624.59,664.25,146.3,311.55.3,288.5.17,860.1,864.14,860.38,914.3,220.2,514.5,152.2,640.2,660.2,640.6,660.4,204.50,424.62,700.27,720.13,200.7,920.20,992.10,000.85,338.40,918.ft I,cs formalités prescrites aux paragraphes 1 et 2 de l'article 430 de la Loi des Cités et Villes, ont été accomplies.Donné a Asbestos, ce 9c jour dc janvier 1970.32773-4-2-0 Le greffier de la ville, Yvon Hamel.The formalities prescribed by paragraphs 1 and 2 section 430 of the Cities and Towns Act, have been observed.Given at Asbestos, this 9th day of January 1970.Yvon Hamel, 32773-4-2-q Town Clerk: 2500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n\" 17 La Corporation des administrateurs agréés du Québec The Corporation of Chartered Administrators of Québec Avis est donné que, par arrêté en conseil numéro 1574, en date du 8 avril 1970, il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver un règlement modifiant les règlements généraux de « La Corporation des administrateurs agréés «lu Québec \u2014 The Corporation of Chartered Administrators of Québec», conformément à l'article 6 du chapitre 128 «les lois de 1966/1967.Le .sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.34245-0 12188-1954 Caisses d'épargne et de crédit Caisse Populaire St-Pic X de Laval (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et cooj>ératives, a approuvé le règlement adopté le 31 mars 1970 par « La Caisse Populaire Si-Pic X (St-Martin) », changeant son nom en celui «le « Caisse Populaire St-Pie X de Laval ».Québec, le 17 avril 1970.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 34246-0 Ls-Phiuppe Bouchard.Ministère dc l'Éducation La Corporation des administrateurs agréés du Québec The Corporation of Chartered Administrators of Québec Notice is given that, by Order in Council number 1574, dated April 8,1970, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to approve a by-law amending the general by-laws of \"La Corporation des administrateurs agréés du Québec\u2014 The Corporation of Chartered Administrators of Québec\", pursuant to section 6 of chapter 128 of the Statutes of 1966/1967.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaliees.34245 12188-195-1 Savings and Credit Union Caisse Populaire St-Pie X de Lavul (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives has approved the by-law adopted on March 31, 1970, by \"La Caisse Populaire St-Pic X (St-Martin)\", changing its name to that of \"Caisse Populaire St-Pie X de Laval\".Québec, April 17, 1970.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 34246 Companies and Coopéralires.Department of Education Commission scolaire régionale Le Royer Conformément à l'article 474 «le la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), avis est donné que, par résolution datée du 17 mars 1970, la Commission scolaire régionale Le Royer a changé son siège social de Montréal-Est à la ville de Pointe-aux-Trembles.Québec, ce 15 avril 1970.Le ministre de l'Éducation, 34225 Jean-Guy Cardinal, Sherbrooke Demande est faite d'annexer le territoire actuel «le la municipalité scolaire de Saint-Élie-d'Orford, dans le comté de Sherbrooke, au territoire sous la juridiction de la Commission des Écoles Catholiques de Sherbrooke.Québec, le 21 avril 1970.Le ministre de l'Éducation, Jean-Guy Cardinal.34249-17-2-0 165-01 Regional School board of Lc Royer Pursuant to section 474 of the Education Act (Revised Statutes 1964, chapter 235), noticcjs given that by resolution dated March 17, 1970.the regional school board of Lc Royer has changed its head office from Montreal East to the Town of Pointe-aux-Trembles.Québec, April 15, 1970.Jean-Guy Cardinal, 34225 Minister of Education.Sherbrooke Application is made to annex the present territory of the school municipality of Suinl-Élic-d'Orford, in the County of Sherbrooke, to the territory under the jurisdiction of the Sherbrooke Catholic School Commission.Québec, April 21, 1970.Jean-Guy Cardinal, ill mister of Education.34249-17-2 165-01 Ministère de l'Industrie Department of Industry et du Commerce and Commerce Loi sur les pêcheries Règlement de pêche du Québec Avis de pêche aux coquillages Vu la décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social à l'effet que les coquillages des régions coquillièrcs situées le long des côtes et des eaux : Fisheries Act Québec Fishery Regulation Notice of Clam Fishing In view of the decision rendered by the Minister of National Health and Welfare to the effect that clams in shellfish areas situated along the shores and waters: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2501 N-2.1 \u2014 région s'étendant de Les Escoumins - Ilets Penchés ne sont plus toxiques à un point qui les rend dangereux pour la consommation à létal cru.À ces causes et conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Règlement de pêche du Québec, par les présentes, il plaît au ministre d'ouvrir lesdites régions à la pêche et de permettre à quiconque de pêcher, de prendre ou d'avoir en sa possession (les coquillages provenant desdites régions.Québec, lc 13 avril 1970.Le ministre de l'Industrie et du Commerce, 31252 Jean-Paul Beaudry.Commission Municipale de Québec Cité dc la Pointc-aux-Trcmbles Avis est par les présentes donné que la Commission municipale de Quéliec, à sa séance en date du 21 avril 1970, a adopté la résolution suivante: « Il est résolu (pic, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi de la Commission municipale (S.R.Q.1964, c.170), la cor|M>ration de la cité dc la Pointc-aux-Trcmblcs.circonscription électorale de Lafontainc, ne soit plus, à compter du 1er mai 1970, considérée comme étant en défaut au sens dc la section V de Indite loi.*.Québec, le 21 avril 1970.Le secrétaire, 34260-o Roger Desaulniers; N-2.1 \u2014 area extending from Les Escoumins \u2014 Ilets Penchés are no longer toxic to a degree unsafe for use as a rare food.Therefore, pursuant to section 6, paragraph 1 .of the Québec Fishery Regulation, the Minister is hereby pleased to open the said areas to fishing, and to permit whomsoever to fish, to take or to have in his possession clams from I In-said areas.Québec, April 13, 1970.Jean-Paul Beaudry, 34252 Minister of Industry and Commerce.Québec Municipal Commission City de la Pointe-aux-Trcmblcs Notice is hereby given that the Québec Municipal Commission has adopted the following resolution at its sitting of April 21,1970.\"Resolved that in accordance with the provisions of section 52 of the Municipal Commission Act (R.S.Q.1964, c.170), from and after May 1, 1970, the corporation of the city de la Pointeaux-Trembles, electoral district of l.afonlainc, shall no longer be considered in default within the meaning of division V of the said act.\".Québec.April 21, 1970.Roger Desaulniers, 34200-o Secretary.Ministère des Terres et Forêts Department of Lands and Forests Cadastre Cadastre Canton dc Bourlamaquc Cadastre officiel du canton dc Bourlamaquc, division d'enregistrement d'Abilibi.Avis est par ln présente donné que le bloc « A » est ajouté en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 10 février 1970.Le sous-ministre, 34253-0 Fernand Boutin.Canton de llonthillier Cadastre officiel du cunton dc Bouthillicr.municipalité dc St-Aimé du Lac des Iles, division d'enregistrement de Lubelle.Avis est par la présente donné que les lots 70 à 106 du rang « A» sont ajoutés et que les lots 1 à 69 du rang « A » sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 7 avril 1970.Le sous-ministre, 34253-0 Fernand Boutin.Canton de ïAMivicourl Cadastre officiel du canton de Louvicourt, division d'enregistrement (l'Abitibi.Avis est par la présente donné que le bloc « D » est ajouté en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Quéliec, le 16 février 1970.Le sous-ministre, 34253-o Fernand Boutin.Township of Bourlamaquc Official cadastre of township of Bourlamaque, registration division of Abitibi.Notice is hereby given that the block \"A\" is added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 16, 1970.Fernand Boutin, 34253-0 Dcpuly Minister.Township of Bouthillicr Official cadastre of township of Bouthillicr, municipality of St-Aimé du Lac des Iles, registration division of I .allelic.Notice is hereby given that lots 70 to 106, range « A » are added and that lots 1 to 69, range « A » are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quéliec, April 7, 1970.Fernand Boutin, 34253-o Deputy Minister.Township of Louvicourt Official cadastre of township of Louvicourt, registration division of Abitibi.Notice is hereby given tliat the block \"D\" is added in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, February 16.1970.Fernand Boutin, 34253-0 Deputy Minister. 2502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n\" 17 Canton de Halifax (Partie révisée) Cadastre officiel du canton dc Halifax, (Partie revisée), municipalité du village de Bernier-ville, division d'enregistrement de Mégantic.Avis est par la présente donné que les lots 1422-1 à 1422-4 sont annulés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 18 mars 1970.Le sous-minislre, 34253-0 Fernand Boutin.Canton Lnssier Cadastre officiel du canton Lussier, municipalité de St-Donat, division d'enregistrement de Montcalm.Avis est par la présente donné que les blocs N.O.P.Q.R.S.et T.sont ajoutés et que le lot 29-30 du rang 11 est corrigé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 6 avril 1970.Le sous-minislre, 34253-0 Fernand Boutin.Canton Provost Cadastre officiel du canton Provost, municipalité de la paroisse dc St-Zénon, division d'enregistrement de Ilerthier.Avis est par la présente donné que les lots 14-A-l à 14-A-17 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 avril 1970.Le sous-minislre, 34253-0 Fernand Boutin.Paroisse de St-Ambroise de la Jcune-Lorettc (Partie révisée) Cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise dc la Jeune-Lorette (Partie revisée), municipalité de la Cité de Lorctteville, division d'enregistrement dc Québec.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 636-10-2 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 2 avril 1970.Le sous-minislre, 34253-0 Fernand Boutin.Village dc Ste-Anne dc Chicoutimi Cadastre officiel du village de Ste-Anne de Chicoutimi, municipalité de la cité de Chieoutimi-N'ord, division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que le lot 34-154 du rang 1 ouest, canton Tremblay est annulé en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 avril 1970.Le sous-minislre, 34253-0 Fernand Boutin.Paroisse de St-Colomh de Sillery Cadastre officiel de la paroisse de St-Colomb de Sillery, municipalité de la cité «le Sillery, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné que les lots 3-19 à 3-24 sont annulés en vertu dc l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 avril 1970.Le sous-minislre, 34253-o Fernand Boutin.Township of Halifax (Part Revised) Official cadastre of township of Halifax, (Part revised), municipality of village of Bcrnicr-villc, registration division of Mégantic.Notice is hereby given that lots 1422-1 lu 1422-4 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, March 18, 1970.Fernand Boutin, 34253-o Deputy Minister.Township of Lussier Official cadastre of township Lussier, municipality of St-Donat, registration division of Montcalm.Notice is hereby given that blocks N.O.P.Q.-R.S.and T.are added and that lot 29-36 range 11 is corrected in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, April 6, 1970.Fernand Boutin, 34253-d Deputy Minister.Township of Provost Official cadastre of township Provost, municipality of the parish of St-Zénon.registration division of Berthier.Notice is hereby given that lots 14-A-l In 14-A-17 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec.April 2.1970.Fernand Boutin.34253-0 Deputy Minister.Parish of St-Ambroise dc la Jcune-Lorcltc (Part Revised) Official cadastre of the parish of St-Ambroi.se de la Jeune-Lorette (Part revised), municipality of the City of Lorctteville, registration division of Québec.Notice is hereby given that a remaining pari of lot 636-10-2 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, April 2, 1970.Fernand Boutin.34253-0 Deputy Minister.Village of Ste-Anne dc Chicoutimi Official cadastre of village of Ste-Anne dc Chicoutimi, municipality of the city of Chicoutimi North, registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that lot 34-154, range I west, township Tremblay is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code Québec, April 9, 1970.Fernand Boutin, 34253-0 Deputy Minister.Parish of St-Colomb de Sillery Official cadastre of the parish of St-Colomb dc Sillery, municipality of the city of Sillery.registration division of Quéliec.Notice is hereby given that lots 3-19 to 3-21 arc cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, April 9, 1970.Fernand Boutin, 34253-o Deputy Minister. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2503 Paroisse dc St-Laurcnt Cadastre officiel de la paroisse de St-Laurent, municipalité de la cité de Montréal, division «l'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que la partie du lot 344-962 est annulée en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 8 avril 1970.Le sou.i-miiii.itre, 34253-o Fernand Boutin.Soumissions Canton de Grand-Calumet Comté de Pontiac Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné .1.O.Mantha, secrétaire-trésorier, Salle municipale, Grand-Calumet, comté dc Pontiac, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 12 mai 1970, pour l'achat de SI 17,000 d'obligations de Canton dc Grand-Calumet, comté dc Pontiac, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à SJ-2%, ni supérieur à 9j-4%, payable semi-annucllcmcnt les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement \u2014 3117,000 ¦\u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.S 4,500 1er juin 1972.4,000 1er juin 1973.4,000 1er juin 1974.3,500 1er juin 1975.3,000 1er juin 1976.:.2,500 1er juin 1977.2,000 1er juin 1978.1,500 1er juin 1979.1,000 1er juin 1980.1,000 1er juin 1981.500 1er juin 19S2.500 1er juin 1983.500 1er juin 1984.500 1er juin 1985 .500 1er juin 1986.1.000 1er juin 1987.1,000 1er juin 1988.1,000 1er juin 1989.1,500 1er juin 1990 .83,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde il courte échéance 10 uns pour une partie et 'autre partie à terme fixe 20 ans.Parish of St-Lnurent Official cadastre of the parish of St-Laurent, municipality of the city of Montreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that a part of lot 344-962 is cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, April 8, 1970.Fernand Boutin, 34253-0 Deputy Minister.Tenders Township of Grand-Calumet County of Pontiac Public notice is hereby given that sealed tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, 3.0.Mantha, Secrctary-Trcusurer, Municipal Hall, Grand-Calumet', County of Pontiac, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Tuesday, May 12, 1970, for the purchase of an issue of $117,000 of bonds of the Township of Grand-Calumet, County of Pontiac, dated .lune 1, 1970 and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rale of not less than 8J^%, nor more thant 9J4%, payable semi-annually on June 1st and December 1st c~ch year.The rate of interest may be the same fc: the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at euch different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption of this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 8117,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.$ 4,500 June 1, 1972 .4,000 June 1,1973 .4,000 June 1, 1974 .3,500 June 1, 1975 .3,000 June 1, 1976 .2,500 June 1, 1977 .2,000 June 1, 197S.1,500 June 1, 1979.1,000 June 1, 1980.1,000 June I, 1981.500 June 1, 1982.500 June 1,1983 .500 June 1, 1984 .500 June 1, 1985.500 June 1, 1986.1,000 June 1, 1987.1,000 June 1, 1988.1,000 June 1, 1989.1,500 June 1, 1990 .83,000 Moreover, .the following terms and conditions only shall be considered : (1) Five-year, or 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.(3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.(4) Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-yeur fixed-term bonds for the other part. 2504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie ù ternie fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 0°, les obligations échéant ù terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur ù $8,500, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que «les amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera ù terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément ù la loi.L'échéance du 1er juin 1990 au montant dc $83,000 comprend un solde dc $81,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Année l'apilal 1er juin 1991.$1,500 1er juin 1992.2,000 1er juin 1993 .2,000 1er juin 1994 .2,000 1er juin 1995 .2,500 1er juin 1996 .2,500 1er juin 1997 .3,000 1er juin 1998 .3,000 - ler juin 1999 .3,000 1er juin 2000.3,500 1er juin 2001 .3,500 1er juin 2002.4,000 1er juin 2003.4,500 1er juin 2004 .5,000 1er juin 2005 .5,000 1er juin 2006.5,500 1er juin 2007 .6,000 1er juin 2008.7,000 1er juin 2009 .7,500 1er juin 2010.8,500 L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Campbell's Hay.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Quéliec dc la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto et à Ottawa, Ontario.Lesditcs obligations ne seront pas rachctables par anticipai ion si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de $83,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $83,000, les obligations ainsi émises seront rachetablcs par anticipation, au pair, le 1er juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal ù 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.(5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.(6) Five-year short-term serial bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and (i, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than $8,500, and if greater than the latter amount, said part must comprise only one or more complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice and starting with the last years of maturities in the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-year or 10-year short-term bonds shall comprise complete annual amortizations only, and starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term pari.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The June 1, 1990 maturity in the amount of $83,000 comprises a balance of $81,500 renewable for an additional 20-ycar period und maturing as follows: Year Capital June 1, 1991.$1,500 June 1, 1992 .2,000 June 1,1993.2,000 June 1, 1994.2,000 June 1, 1995.2,500 June 1, 1996.2,500 June 1, 1997 .3,000 June 1, 1998 .3,000 June 1, 1999.3,000 June 1, 2000 .3,500 June 1,2001.3,500 June 1,2002.4,000 June 1,2003 .4,500 June 1,2004.5,000 June 1,2005.5,000 June 1,2006.5,500 June 1,2007 .6,000 June 1,2008 .7,000 June 1, 2009.7,500 June 1.2010 .8,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Campbell's Hay.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, and Ottawa, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds for an amount equal to or less than $83,000.However, should they be issued partly as 20-ycar fixed-term bonds for an amount greater than $83,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the tables of redemption of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2505 Lesdites obligations seront émises en vertu «les règlements suivants: 98 \u2014 812,000 \u2014 aqueduc, égouts; 99 \u2014 $105,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 12 mai 1970, à 8 heures du soir.Salle municipale.(irand-Calumct, comté dc Pontiac, P.Q.I.e conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Grand-Calumet (Comté dc Pontiac), ce 15 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, .1.O.Mantua.Salle municipale, Grand-Calumet (Pontiac), P.Q.Téléphone: 048-5965.code 819.34221-0 l.e- commissaires d'écoles pour la municipalité de Montcalm Comté dc St-Sauveur Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Leopold Bérubé, secrétaire-trésorier, bureau du secrétaire, 1400, Place Tassé, district Les Saules, Québec, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 11 mai 1970, pour l'achat de $283,000 d'obligations pour les commissaires d'écoles pour la municipalité de Montcalm, comté dc Saint-Sauveur, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 ut 1er juin 1980 inclusivement, avec intérêt ù un taux non inférieur à 8>2%.ni supérieur à payable scmi-annucllemcnt les 1er juin et 1er décembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis ù chaque taux different doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tnbleau d'amortissement dans le présent avis.Résolutions datées: 20 janvier 1960 \u2014 889,000 \u2014¦ renouvellement d'emprunt: IS murs 1970 \u2014 $194,000 \u2014 dépenses d'immobilisation dc 1966-67 à 1969-70.Pour adjudication .seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement - S2S3.000 \u2014 10 ans Annie Capital 1er juin 1971.$20,500 1er juin 1972.21,500 1er juin 1973 .23,500 1er juin 1974 .25,500 1er juin 1975 .27,500 1er juin 1976.30,000 1er juin 1977 .32,500 1er juin 1978 .35,000 1er juin 1979 .39,000 1er juin 1980.28.000 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 5 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des 2 modes d'émission ci-haut.L'adjudication sera fuite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Québec.Ia; capital et les intérêts sont payable à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont lc nom est mentionné dans lu procédure «l'emprunt.The said bonds will be issued in pursuance of the following by-laws: 98 \u2014 $12,000 \u2014 aqueduct, sewers; 99 \u2014 $105,000 \u2014 aqueduct, sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held Tuesday, May 12, 1970, at 8:00 p.m., in the Municipal Hall, Grand-Calumet, County of Pontiac, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Grand-Calumet (County of Pontiac), April 15, 1970.J.O.Mantua, Secretary-Treasurer.Municipal Hall, Grand-Calumet (Pontiac), P.Q.Telephone: 648-5905, code 819.34221 The School Commissioners for the Municipality of Montcalm County of St-Sauveur Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Leopold Bérubé, Secretary-Treasurer, Office of the Secretary, 1400 Place Tassé, district of Les Saules, Québec, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m., on Monday, May 11, 1970, for the purchase of an issue of $283,000 of bonds for the school commissioners for the municipality of Montcalm, county of Saint-Sauveur, dated June 1, 1970 and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1980 inclusively, with interest at a rate not less than 8J^%, nor more than 9}>%, payable semi-annually on June 1st and Dccemlier 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tabic of redemption in this notice.Resolutions dated: January 20,1960 \u2014 $89,000 - renewal of a loan; March 18, 1970 \u2014 $194,000 \u2014 1966-67 to 1969-70 immobilization expenses.For adjudication only, interest shall be calculated as from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 $283,000 \u2014 10 years Year Capital June 1, 1971.$20,500 June 1, 1972 .21,500 June 1, 1973 .23,500 June 1, 1974 .25,500 June 1, 1975.27,500 June 1, 1976 .30,000 June 1, 1977 .32,500 June I, 1978 .35,000 June 1, 1979.39,000 June 1, 1980 .28,000 Moreover, tenders may be sent and shall be taken into consideration for serial bonds at 5-year short-term.However, the tenders shall Ik?sent for one only of the 2 methods of issue hercabovc.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to puy for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Quéliec.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure. 2506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Lesdites obligations ne seront pas ruchctables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée «l'un chè«pjc ucœpté égal à 1% «lu montant «le l'emprunt et devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'woles qui sera tenue, lundi, lc 11 mai 1970, à 8 heures «lu soir, bureau du secrétaire, 1400, Place Tassé, district Les Saules, Québec, P.Q., lycs commissaires d'écoles se réservent lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Québec (Comté «le Saint-Sauveur), ce 13 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, Leopold Bun m .Bureau du secrétaire, 1400, Place Tassé, District Les Saules, Québec, P.Q.Téléphone : 683-2941, code 418.34222-0 Ville «lc Princevlllë Comté d'Arthabaska Avis public est par les présentes donné «pie des soumissions cachetées et en«lossécs « Soumissions |k>ur obligations » seront reçues par le soussigné Fernand Poiré, secrétaire-trésorier, Hôtel dc ville, 25, rue St-.Iacqucs-Ouest, case postale 279, Princeville, comté d'Arthalmska, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 12 mai 1970, pour l'achat de 8110,000 d'obligations «le la ville dc Princeville, comté d'Arthabaskn, datées «lu 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 nu 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8|^%, ni supérieur ù 9J-2%, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Lc taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent «loit couvrir un ou «les amortissements annuels entiers, tels que montrés nu tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement no: 205 \u2014 8110,000 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be uccompunicd by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered al a meeting of the school commissioners to be held on Monday, May 11, 1970, at 8:00 o'clock, p.m., at the Office of the Secretary, 1400 Place Tassé, district of Les Saules, Québec, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders, Québec (Countv of Sainl-Sauvcur), April 13, 1970.Leopold Bkiiibk, Secretary-Treasurer.Office of the Secretary, 1400 Place Tassé, District of Les Saules.Québec, P.Q.Telephone: 683-2941, croie 418.34222 Town of Princeville County of Arthabaska Public notice is hcr«d)y given that scaled tenders endorsee! \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Fernand Poiré.Secretary-Treasurer, Town Hall, 25 St-Jacques Street West, P.O.Box 279, Princeville, countv of Arthabaska, P.Q., until 8:00 o'clock p.m.Tuesday, May 12, 1970, for the purchase of an issue of 8110,000 of bonds for the town of Princeville, county of Arthabaska, dated June 1, 1970 anil redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rale not less than 8} 2%.nor more than 9J^%, payable semi-annually on June 1st und December 1 si of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or more complete annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice By-law No.205 - 8110,000 - loan renewal.For adjudication only, interest shall be calculated as from June 1, 1970.Tableau d'amortissement - $110,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.83,000 1er juin 1972.3,500 1er juin 1973 .3,500 1er juin 1974 .3,500 1er juin 1975.4,000 1er juin 1976.4,000 1er juin 1977 .4,500 1er juin 1978.4,500 1er juin 1979 .5,000 1er juin 1980 .5,000 1er juin 1981.5,500 1er juin 1982 .5,500 1er juin 1983.6,000 1er juin 1984.6,500 1er juin 1985.6,500 1er juin 1986.7,000 1er juin 1987 .7,500 1er juin 1988 .8,000 1er juin 1989 .8,500 1er juin 1990 .8,500 Table of redemption \u2014 SI 10,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.83.000 June 1, 1972 .3,500 June 1, 1973.3,500 June 1, 1974 .3,500 June 1, 1975 .4,000 June 1.1976.4,000 June 1, 1977 .4,500 June 1, 1978 .4,500 June 1, 1979 .5,000 June 1, 1980 .5,000 June 1, 1981.5,500 June 1, 1982 .5,500 June 1, 1983 .6,000 June 1, 1984.6,500 June 1, 1985 .6,500 June 1, 1986.7,000 June 1,1987 .7,500 June 1, 1988 .8,000 June 1, 1989 .8,500 June 1, 1990.8.5(H) QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2507 En plus, les modalités suivantes seulement, seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre parte ù terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à §8,500, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Egalement, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le eus des exceptions notées.L'adjudication seru fuite conformément ù lu loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations capital et intérêts courus, s'il y u lieu, pur chèque visé, payable un pair n Princeville.I,e capital et les intérêts sont payables n toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont lc nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pus rachetables pur anticipation si elles sont émises pur séries ou en séries et terme fixe 20 uns pour un montant égul ù SS.500.Toutefois, si elles sont émises en partie ù terme fixe 20 uns pour un montant supérieur ù 88,500, les obligations uinsi émises seront rachetables par anticipation au pair, le 1er juin, de chaque année pour le montant annuel requis, pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations nu moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 12 mai 1970, à 8 heures du soir.Hotel de'ville, 25, rue Saint-Jacques-Ouest, case postule 279, Princeville, comté d'Arthabaska, P.Q.Lc conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Princeville (Comté d'Arthabaska), ce 14 avril 1970.Le secrélaire-trê.iorier, Fernand Poiré.Hôtel de ville, 25, rue St-Jacques-Ouest, Case postale 279, Princeville, comté d'Arthubusku, P.Q., Téléphone: 304-5179, code 819.34223-0 Moreover, the following terms ami conditions only shall be considered: (1) Five year, or 10-year or 15-ycar short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.(3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.(4) Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.(5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.(0) Five-year short-term serial bonds for one purt und 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 und 6, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than 88,500 and if higher than the latter amount, said part must comprise only one or more complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice and starting by the last years of maturities.Also five-year or 10-year short-term bonds shall comprise only complete annual amortizations, und sturting by the lust years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of the exceptions stipidatcd herein.Adjudication -hall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Princeville Capital and interest arc payable at nil brunches in the province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure.The said bonds will not l>c redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially und for 20-ycar fixed-term bonds for an amount equal to 88,500.However, should they lie issued partly us 20-year fixed-term for un nmount higher than 88,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year for the animal nmount required to umortizc the issue in accordance with the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tenders.Tenders will opened und considered ut a meeting of the council to be held on Tuesday, May 12, 1970, at 8:00 o'clock p.m., Town Hall, 25 St-Jacques West Street, P.O.Ilox 279, Prince-vill, county of Arthubusku, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Princeville (County of Arthubusku), April 14, 1970.Fernand Poire, Secretary- Treasurer.Town Hull, 25 St-Jucqucs Street West, P.O.Box 279, Princeville, countv of Arthubusku, P.Q., Telephone: 304-5179, code 819.34223 2508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Ville de Saint-Antoine Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée (Jinette Trudcllc, greffier.Hôtel dc ville, 854, Houle van I St-Antoine, St-Antoine, comté dc Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 11 mai 1970, pour l'achat dc $214,500 d'obligations dc la ville de St-Antoine, comté de Terrebonne, datées du 1er mai 1970 et remboursables en séries du 1er mai 1971 au 1er mai 1980 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J^%, ni supérieur à 9J4%, payable semi-annuellcmcnt les 1er mai et 1er novembre dc chaque année.I/c taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Règlement numéro 9 \u2014 $214,500 \u2014 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er mai 1970.Tableau d'amortissement \u2014 82t/,,600 \u2014 10 ans Année Capital 1er mai 1971.$16,500 1er mai 1972.17,500 1er mai 1973.18,500 1er mai 1974.19,500 1er mai 1975.20,500 1er mai 1976.22,000 1er mai 1977.23,000 1er mai 1978 .24,500 1er mai 1979 .25,500 1er mai 1980.27,000 Dc plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations en séries à courte échéance 5 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des 2 modes d'émission ci-haut.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Antoine.Le capital et les intérêt sont payables à toutes les succursales dans la province de Quél>cc dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque ù Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 11 mai 1970, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 854, Boulevard St-Antoine, St-Antoine, comté dc Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Antoine (Comté dc Terrebonne), ce 15 avril 1970.Le greffier, Mlle Ginette Trudelle.Hôtel de ville, 854, Boulevard St-Antoine, St-Antoine (Terrebonne), P.Q.Téléphone: 436-1762, code 514.34238-o Town of Saint-Antoine County of Terrebonne Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will he received by the undersigned, Ginette Trudcllc, Town clerk, Town Hall, 854 St-Antoinc Boulevard, St-Antoinc, county of Terrebonne, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Monday, May 11, 1970, for the purchase of an issue of $214,500 of bonds for the town of St-Antoinc, county of Terrebonne, dated May 1, 1970 and redeemable serially from May 1, 1971 to May 1, 1980 inclusively, with interest at a rate not less than S\\4%< nor more than 9J^%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in the present notice.By-law number 9 \u2014 $214,500 \u2014 loan renewal.For adjudication only, interest shall be calculated as from May 1, 1970.Table of redemption \u2014 S21.',,500 \u2014 10 ans Year Capital May 1, 1971.$16,500 May 1, 1972.17,500 May 1, 1973.18,500 May 1,1974.19,500 May 1, 1975.20,500 May 1,1976.22,000 May 1,1977.23,000 May 1, 1978 .24,500 Mav 1, 1979 .25,500 May 1, 1980.27,000 Moreover, tenders may be forwarded and shull be considered as 5-year scriul short-term bonds.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any by certified cheque payable at par at St-Antoinc.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the present issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be o'|>encd and considered at u meeting of the council to be held on Monday, May 11, 1970, at 8:00 o'clock p.m., Town Hall.854 St-Antoine Boulevard, St-Antoine, county of Terrebonne, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Antoinc (County of Terrebonne), April 15, 1970.Miss Ginette Trudelle, Town Clerk.Town Hall, 854 St-Antoine Boulevard, Saint-Antoinc (Terrebonne), P.Q.Telephone: 436-1762, code 514.3423S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2509 Paroisse de St-Pierre-de-ln-Rivière-du-Siid Comté de Montmagny Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par lc soussigné J.-Paul Poirier, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heures du soir, bureau de la corporation, St-Pierrc-de-la-Rivièrc-du-Sud, comté de Montmagny, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, salle paroissiale, St-Picrre-dc-la-Rivièrc-du-Sud, comté de Montmagny, P.Q., mardi, le 12 mai 1970, pour l'achat dc 895,000 d'obligations dc la paroisse dc St-Picrrc-de-la-Rivièrc-du-Sud, comté de Montmagny, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8^% ni supérieur à 9^2%, payable scmi-annucllement les 1er juin et 1er décembre dc chaque année.\\x taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré nu tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement \u2014 S!)5,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.S 500 1er juin 1972 .500 1er juin 1973 .500 1er juin 1974 .500 1er juin 1975 .500 1er juin 1976 .500 1er juin 1977 .500 1er juin 1978 .500 1er juin 1979 .500 1er juin 1980 .500 1er juin 1981.1,000 1er juin 1982.1,000 1er juin 1983.1,000 1er juin 1984.1,000 1er juin 1985.1,000 1er juin 1986.1,000 1er juin 1987.1,000 1er juin 1988.1,500 1er juin 1989.1,500 1er juin 1990 .80,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à tenue fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans lc cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $7,500, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années Parish of St-Picrre-de-la-Rivicre-du-Sud County of Montmagny Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, J.-Paul Poirier, Secretary-Treasurer, until 7:30 o'clock p.m., office of the Corporation, St - Pierre - de - la - Rivière - du -Sud, county of Montmagny, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., Parish Hall, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, county of Montmagny, P.Q., Tuesday, May 12, 1970, for the purchase of an issue of $95,000 of bonds for the parish of St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, county of Montmagny, dated June 1, 1970, and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8J-£%, nor more than !\u2022'_\u2022'('.payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from June I, 1970.Table of redemption - $95,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.$ 500 June 1, 1972 .500 June 1,1973 .500 June 1, 1974 .500 June 1, 1975 .500 June 1, 1976 .500 June 1, 1977 .500 June 1, 1978.500 June 1, 1979.500 June 1, 1980 .500 June 1, 1981.1,000 June 1, 1982.1,000 June 1, 1983.1,000 June 1, 1984.1,000 June 1, 1985.1,000 June 1, 1986.1,000 June 1, 1987.1,000 June 1, 1988.1,500 June 1, 1989.1,500 June 1, 1990 .80,000 Moreover, only the following methods shall be considered: (1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance for 20-ycar fixed-term.(3) Ten-year serial bonds with the balance for 5-year short-term.(4) Ten-year serial bonds with the balance partly for 10-year short-term and partly for 20-ycar fixed-term.(5) Ten-year serial bonds with the balance partly for 5-year short-term and partly for 20-ycar fixed-term.(6) Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-ycar fixed-term for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-ycar fixed-term bonds shall lie for an amount not less than $7,500, and, if higher than this latter amount, the said part shall comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the lust years of maturities of the renewable part hereinafter 2510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2B avril 1970, 102' année, n\" 17 d'échéances air ù Montmugny.I* capital et les intérêts sont payables ù toutes les succursales dans lu province de Québec dc lu banque dont lc nom est mentionné duns In procédure d'emprunt.Lesdites obligutions ne seront pus rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc $80,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur fi $80,000, les obligations ninsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances de l'émission apparaissant duns le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal ù 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations uu moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 72(74)\u2014$95,000\u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance du conseil qui sera tenue mardi, lc 12 mai 1970, à 8.heures du soir, salle paroissiulc, St-Picrrc-de-la-Rivièrc-du-Sud, comté de Montmagny, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.mentioned.Also, 5-year or 10-ycar short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, starting by the last years of maturities excluding the 20-year fixed-term |>art.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The June 1, 1990 maturity in the amount of $80,000, comprises a balance of $78,500, renewable for an additional 20-year period, and maturing as follows: Year Capital June 1, 1991.$1,500 June 1, 1992 .2,000 June 1, 1993 .2,000 June 1,1994.2,000 June 1, 1995.2,500 June 1, 1996.2,500 June 1, 1997.2,500 June 1, 1998.3.000 June 1,1999.3,000 June 1,2000 .3,500 June 1,2001.3,500 June 1,2002 .4,000 June 1,2003 .4,500 June 1,2004 .4,500 June 1,2005 .5,000 June 1,2006 .5,500 June 1.2007.6,000 June 1,2008 .6,500 June 1,2009 .7,000 June 1,2010.7.500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable ut pur at Montmagny.Capital und interest arc payable at all brunches in the Province of Québec of the hank mentioned in the loan procedure The said bonds will not Ik- redeemable by anticipation if they ure issued serially or serially and for 20-year fixed-term for un amount equul to or less than $80,000.However, if they arc issued partly for20-ycur fixed-term for an amount greater than $80,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice Each tender must be accompanied by n certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued under the following by-laws: 72(74) \u2014 $95,000 \u2014 aqueduct, sewers.The tenders will be opened and considered ut a meeting of the council to be held on Tuesday, May 12, 1970, at 8:00 o'clock p.m., in the Parish Hall, St-Picrrc-de-la-Rivière-du-Sud, county of Montmagny, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2511 St - Pierre - de - la - Rivière - du - Sud (Comté de Montmagny), ce 15 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, .I.-PAur, Poirier.llureau de la corporation, St-Pierre-dc-la-Rivièrc-du-Sud, Comté de Montmagny, P.Q.Téléphone: 248-3788, code 418.34224-o St - Pierre - dc - la - Rivière - du - Sud (County of Montmagny), April 15, 1970.J.-Paul Poiuikk, Secretary-Treasurer.Office of the Corporation, St-Picrrc-de-la-Rivièrc-du-Sud, County of Montmagnv, P.Q.Telephone: 248-3788, code 418.34224 Ville de Sainl-Césairc Comté dc Rouvillc Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné .1.A.D.Dion, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 1111, Avenue St-Paul, C.P.570, St-Césairc, comté dc Rouvillc, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, lc 13 mai 1970, pour l'achat de $111,000 d'obligations dc la ville de St-Césairc, comté dc Rouvillc, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8}-£%, \"i supérieur à 9^£%, payable scmi-annucllemcnt les 1er juin et 1er décembre dc chaque année.Le taux d'intérêt |x'ut être le même pour toute l'émission ; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans lc présent avis.Règlement no 271 - $111,000 \u2014 renouvellement d'emprunt.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé ù compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement SI II,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.$3,000 1er juin 1972.3,000 1er juin 1973.3,500 1er juin 1974.3,500 1er juin 1975.4,000 1er juin 1970 .4,000 1er juin 1977 .4,500 1er juin 1978 .4,500 1er juin 1979 .5,000 1er juin 1980 .5,000 1er juin 1981.5,500 1er juin 1982.'5,500 1er juin 1983 .6.000 1er juin 1984 .6.500 1er juin 1985.7,000 1er juin 1986.7,500 1er juin 1987 .7,500 1er juin 1988.8,000 1er juin 1989.8,500 1er juin 1990 .9,000 Town of Saiiit-Césaire County of Rou vil It-Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned J.A.D.Dion, Secretary-Treasurer, Town Hall, 1111 St-Paul Avenue, P.O.Box 570, St-Césairc, county of Rouvillc, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m., on Wednesday, May 13, 1970, for the purchase of an issue of $111,000 of bonds for the town of St-Césaire, county of Rouville, dated June 1, 1970 and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8J^%, nor more than 9^2%, payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tabic of redemption in this notice.By-law Xo.271 \u2014 $111,000 \u2014 renewal of a loan.For adjudication only, interest shall be calculated us from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 $111,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.$3,000 June 1, 1972 .3,000 June 1,1973 .3,500 June 1, 1974 .3,500 June 1, 1975.4,000 June 1,1976 .4,000 June 1,1977 .4,500 June 1, 1978 .4,500 June 1,1979 .5,000 June 1, 1980 .5,000 June 1, 1981.5,500 June 1,1982.5,500 June 1,1983 .6,000 June 1, 1984 .0,500 June 1,1985.7,000 June 1, 1986 .7,500 June 1,1987.7,500 June 1, 1988 .8,000 June 1, 1989 .8,500 June 1, 1990.9,000 En plus, les modalités suivantes seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde à courte échéance 5 ans pour une partie et ' utre partie à terme fixe 20 ans.Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: (1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.(3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.(4) Tnc-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.(5) Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-yenr fixed-term bonds for the other part. 2512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' aimée, n' 17 6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 ans.Toutefois, dans lc cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant a terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $9,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dons le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et en devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage ù paver les obligations, capital et intérêts courus, s'il y n lieu, par chèque visé, payable au pair à St-Césairc.capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipai ion si elles sont émises par séries ou eu séries et terme fixe 20 ans.pour un montant égal ou moindre dc $9,000.Toutefois, si elles sont émises en partie il terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $9,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er juin dc chaque année |k>ur le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le present avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations uu moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui seru tenue mercredi, lc 13 mai 1970, ù 8 heures du soir.Hôtel de ville, 1111, Avenue St-Paul, C.P.570, St-Césairc, comté dc Rouvillc, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni lu plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Césairc (Comté de Rouvillc), ce 15 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, .1.A.D.Dion.Hôtel de ville, 1111, Avenue St-Paul, C.P.570, St-Césairc (Rouvillc).Téléphone: 469-3108, code 514.34239-0 Ville de Longueuil Comté de Chambly Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Robert Boitcau, greffier, Hôtel de ville, 100 ouest, rue St-Charles, Ixmgucuil, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 11 mai 1970, pour l'achat de $1,949,000 d'obligations de la ville de Longueuil, comté dc Chambly, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8^%, ni supérieur it 9) 2%.payable semi-nnnucllement les 1er juin et (6)1 Five-year short-term serial bonds for one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, as far as paragraphs 4, 5 and 0 are concerned, the 20-ycar fixed-term bonds should be for an amount of not less than $9,000, and if greater than the latter amount, the said part should include only one or several complete annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in tis notice and starting by the last years of maturities.Also, the 5-ycar or 10-year short-term bonds shall include complete annual amortizations only, and starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to iiay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable ut par at St-Césuirc.Capital und interest are payable at all branches in the province of Quebec of the bank mentioned in the loan procedure The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and for 20-year fixed-term for un amount equul to or less than $9,000.However, if they arc issued partly us 20-year fixed-term for an amount higher than $9,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must Ik?accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will lie opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, May 13, 1970, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 1111 St-Paul Avenue, P.O.Box 570.St-Césaire, county of Rouvillc, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Césaire (Countv of Rouvillc), April 15.1970.J.A.D.Dion, Secretary-Treasurer.Town Hall, 1111 St-Paul Avenue, P.O.Box 570, St-Césairc (Rouvillc).Telephone: 469-3108, code 514.3423!) City of Longueuil County of Chambly Public notice is hereby given tliat scaled tenders endorsed \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Robert Boiteau.City Clerk, City Hall, 100 St-Charles St.West.Longueuil.P.Q., until 8:00 o'clock p.m., Monday.May 11, 1970, for the purchase of an issue of $1,949,000 of bonds for the City of Longueuil, county of Chambly, dated June I, 1970, and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8J-2%, nor more than 9J-2%, payable semiannually on June 1st and December 1st of each QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2513 $365,000 \u2014 aqueduc, $100,000 \u2014 aqueduc, $300,000 \u2014 aqueduc, $250,000 \u2014 aqueduc, 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans lc présent avis.Règlements nos: 5 \u2014 $43,000 \u2014 éclairage; 13 \u2014 $115,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 033 \u2014 $16,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie services récréatifs et communautaires; 694 \u2014 $32,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 716 \u2014 $160,000 \u2014 éclairage, etc.; 718_\u2014 $140,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; 737 \u2014 $40,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 739 \u2014 $180,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 740 \u2014 égouts et voirie; 742 \u2014 égouts et voirie; 743 \u2014 égouts et voirie; 744 \u2014 égouts, voirie; 749 \u2014 $50,000 \u2014 éclairage, etc.; 1022 \u2014 $52,000 \u2014 services récréatifs et communautaires; 1045 \u2014 $72,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.; 1064 \u2014 $10,000 \u2014 voirie; 1065 \u2014 $4,000 \u2014 voirie; 1067 \u2014 $20,000 \u2014 bâtisses et terrains.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $1,949,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.$ 40,000 1er juin 1972.43,000 1er juin 1973.46,000 1er juin 1974 .52,000 1er juin 1975 .57,000 1er juin 1976 .62,000 1er juin 1977 .68,000 1er juin 1978.73,000 1er juin 1979.79,000 1er juin 1980 .88,000 1er juin 1981.87,000 1er juin 1982 .96,000 1er juin 1983.104,000 1er juin 1984.114,000 1er juin 1985.125,000 1er juin 1986.136,000 1er juin 1987.149,000 1er juin 1988.161,000 1er juin 1989.177,000 1er juin 1990.192,000 year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-laws Nos.5 \u2014 $43,000 \u2014 lighting; 13 \u2014 $115,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 633 \u2014 $16,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, recreational and community services; 694 \u2014 $32,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 716 \u2014 $160,000 \u2014 lighting, etc.; 718 _\u2014 $140,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; 737 \u2014 $40,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 739 \u2014 $180,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 740 \u2014 $365,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 742 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 743 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 744 \u2014 $250,000 \u2014 aqueduct, sewers and roads; 749 \u2014 $50,000 \u2014 lighting, etc.; 1022 \u2014 $52,000 \u2014 recreational and community services; 1045 \u2014 $72,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 1064 \u2014 $10,000 \u2014 roads; 1065 \u2014 $4,000 \u2014 roads; 1067 \u2014 $20,000 \u2014 buildings and lands.For adjudication only, interest will be calculated as from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 SI,91,9,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.$ 40,000 June 1, 1972 .43,000 June 1, 1973 .46,000 June 1, 1974.52,000 June 1, 1975 .57,000 June 1, 1976 .62,000 June 1, 1977.68,000 June 1, 1978 .73,000 June 1, 1979 .79,000 June 1, 1980 .88,000 June 1, 1981.87,000 June 1, 1982 .96,000 June 1, 1983.104,000 June 1, 1984.114,000 June 1, 1985.125,000 June 1, 1986.136,000 June 1,1987.149,000 June 1, 1988.161,000 June 1, 1989.177,000 June 1, 1990.192,000 En plus, les modalités suivantes seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec lc solde ù courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $192,000, et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou îles amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années Moreover, only the following methods shall be considered : (1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.(2) Ten-year serial bonds with the balance for 20-year fixed-term.(3) Ten-year serial bonds with the balance for 5-year short-term.(4) Ten-year serial bonds with the balance partly for 10-ycar short-term and partly for 20-year fixed-term.(5) Ten-year serial bonds with the balance partly for 5-year short-term and partly for 20-year fixed-term.(6) Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-year fixed-term bonds shall be for an amount not less than $192,000, and, if higher than this latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of the maturities.Also, five-year or 10-year 2514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 d'échéance.-.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années il'échéance-, excluant la partie qui sera il terme 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être trunsmiscs que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair il Londueuil.Le capital et les intérêts sont payubles à toutes les succursales dans la province dc Québec île la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc 8192,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8192,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er juin dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins «le l'amortissement de l'émission, conformément uu tableau d'échéances de l'émission uppuruissunt duns le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant «lc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 11 mai 1970, à 8 heures du soir, Hotel «le ville, 100 ouest, rue St-Charlcs, Longueuil.P.Q.Le conseil se réserve lc «Iroit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Longueuil (Comté dc Chamblv), ce 15 avril 1970.Le greffier, Hun i .n r BoiTEAU.Hôtel dc ville, 100 ouest, rue St-Charles, Longueuil (Chamblv), P.Q.Téléphone: 670-2220.code 514.34254-0 Ville de St-Pascul ( 'omté dc Kumourasku Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Simon Lévesque, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, Saint-Pascal, comté dc Kamou-raska, P.Q., jusqu'à 8 heures «lu soir, jeudi, le 14 mai 1970, pour l'achat «le $68,000 d'obligations dc la ville dc Saint-Pascal, comté dc Kamouraska, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt i\\ un taux non inférieur ù 8\\4%> ni supérieur à 9J^%, payable semi-annuellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annucLs entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans lc présent avis.Règlements numéros: 99 \u2014 $38,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.; 104 \u2014 $30,000 \u2014 frais judiciaire.short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, starting by the last years of maturities excluding the 20-year fixéd-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made acrding to law.The successful tenderer ugrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by ccrtified cheque payable at par at Longueuil.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said hank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and for 20-ycar fixed-term for an amount equal to or less than $192,000.However, if they arc issued partly for 20-ycar fixed-term for an amount greater than $192,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipai ion.ut pur.on June 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice, Bach ten«ler must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will he opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday.May 11, 1970, at 8:00 o'clock p.m., in the City Hall, 100 St-Charlcs St.West, Longueuil, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Longueuil (County of Chambly), April 15.1970.Robert Boiteau, Cily Clerk.City Hall, 100 St-Charlcs St.West, Longueuil (Chambly), P.Q.Telephone: 670-2220, code 514.34254 Town of St-Pascal County of Kumourasku Public notice is hereby given that sealed lenders cndorse«l \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Simon Lévesquc.Secretary-Treasurer, Town Hall, Saint-Pascul.county of Kamouraska, P.Q., until 8:00 o'clock, p.m., on Thursday, May 14, 1970, for the purchase of an issue of $68,000 of bonds for the town of Saint-Pascal, county of Kamouraska, dated June 1, 1970 and redeemable serially from June 1.1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8^%, nor more than 9V£%.payable semi-annually on June 1st and December 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice By-laws numbers: 99 \u2014 $38,000 \u2014 aqueduct, sewers, etc.; 104 \u2014 $30,000 \u2014 judicial costs. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2515 Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $68,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.$1,000 1er juin 1972.1,000 1er juin 1973.1,500 1er juin 1974.1,500 1er juin 1975.2,000 1er juin 1976.2,000 1er juin 1977.2,500 1er juin 1978.2,500 1er juin 1979.2,500 1er juin 1980.3,000 1er juin 1981.3,500 1er juin 1982.3,500 1er juin 1983.3,500 1er juin 1984.4,500 1er juin 1985.4,500 1er juin 1986.4,500 1er juin 1987.5,500 1er juin 1988.5,500 1er juin 1989.6,500 1er juin 1990.7,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans ixrnr une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S7.000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annueLs entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans ne devront com-|k)rter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas des exceptions notées.I/adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair n Saint-Pascal.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables l>ar anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal a $7,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $7,000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er juin For adjudication only, interest shall be calculated as from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 S68,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.$1,000 June 1, 1972.1,000 June 1,1973.1,500 June 1,1974.1,500 June 1, 1975.2,000 June 1, 1976 .2,000 June 1, 1977 .2,500 June 1,1978 .2,500 June 1,1979 .2,500 June 1, 1980 .3,000 June 1,1981.3,500 June 1,1982 .3,500 June 1,1983 .3,500 June 1,1984 .4,500 June 1, 1985.4,500 June 1, 1986 .4,500 June 1, 1987.5,500 June 1,1988 .5,500 June 1, 1989 .6,500 June 1,1990 .7,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered.1.Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.2.Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.3.Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds; 4.Ten-year serial bonds with the balance as 10-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term Ixmds for the other part; 5.Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.6.Five-year short-term serial bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, as far as paragraphs 4, 5 and 6 are concerned, the 20-year fixed-term bonds should be for an amount of not less than $7,000, and if greater than the latter amount, the said part should include one only or several complete annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities.Also, the 5-year or 10-year short-term bonds shall include complete annual amortizations only, and starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the case of the exceptions stipulated above.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Pascal.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds for an amount equal to $7,000.However, should they be issued partly as 20-year fixed-termjbonds for an amount greater than $7,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on June 1st 2516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 de chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances dc l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal ù 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.I.es soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, jeudi, lc 14 mai 1970, ù 8 heures du soir.Hôtel dc ville, Saint-Pascal, comté dc Kamourusku, P.Q, Lc conseil se réserve le droit «lc n'accepter ni la plus liaute ni aucune des soumissions.Saint-Pascal (Comté dc Kamouraska), ce 16 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, Simon Leveso.uk.Hôtel de ville.Saint-Pascal (Comté de Kumouraska), P.Q.Téléphone: 492-2917, code 418.34255-o .Municipalité dc Touraine Comté dc Cutincuii Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et endossées < Soumissions pour obligations » seront reçues pur le soussigné Réjean Hupé, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 12, avenue Picardie, Touraine, comté de Gatineau, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 13 mai 1970, pour l'achat de 8291.000 d'obligations de la municipalité de Touraine, comté dc Gatineau, datées du 1er juin 1970 et remboursables par séries du 1er juin 1971 au 1er juin 1990 inclusivement, avec intérêt ù un tuux non inférieur à 8,^2%, ni supérieur ù 9J4%, payable semi-annucllcment les 1er juin et 1er décembre dc chaque année.Lc taux d'intérêt peut être le même |xmr toute l'émission; cependant, si plus «l'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juin 1970.Tableau d'amortissement - $291,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er juin 1971.S 4.000 1er juin 1972 .4,000 1er juin 1973 .4,500 1er juin 1974 .5,500 1er juin 1975 .5,500 1er juin 1976 .4,500 1er juin 1977 .6.000 1er juin 1978.6,000 1er juin 1979 .6,500 1er juin 1980 .7,000 1er juin 1981.8.000 1er juin 1982 .8,000 1er juin 1983 .8,500 1er juin 1984.10,000 1er juin 1985.11,000 1er juin 1986.11,000 1er juin 1987.12,000 1er juin 1988.12,000 1er juin 1989.12,000 1er juin 1090.145,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans ou 10 ans ou 15 ans.of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the tabic of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on tile bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Thursday, May 14, 1970, at 8:00 o'clock, p.m.ut the Town Hull, Saint-Pascal, county of Kamourusku.P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Pascal (County of Kumourusku), April 10, 1970.Simon Levesque, Secretary-Treasurer.Town Hull, Saint-Puscul (County of Kumourusku,) P.Q.Telephone: 492-2917, code 418.34205 Municipality of Totiruinc County of Giitiucau Public notice is hereby given that scaled tenders endorsed \"Tenders for Ronds\" will be received by the undersigned, Réjean Hupé, Secretary-Treasurer, Town Hall, 12 Picardie Ave, Touraine, county of Gatineau, P.Q., until 8:00 o'clock p.m.Wednesday, May 13, 197(1.for the purchase of an issue of $291,000 of bonds for the municipality of Touraine, county of Gatineau, dated June 1, 1970, and redeemable serially from June 1, 1971 to June 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than X1[.nor more than 93 2%, payable semi-annually on June 1st und December 1st of euch year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or more entire annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest will lie calculated us from June 1, 1970.Table of redemption \u2014 $291,000 \u2014 20 years Year Capital June 1, 1971.S 4,000 June 1, 1972 .4.000 June 1.1973 .4,500 June 1, 1974.5,500 June I, 1975 .5.5(H) June 1, 1976.4.5(H) June 1, 1977 .6,000 June 1, 1978 .0,000 June 1.1979 .6.500 June 1, 1980 .7,000 June 1, 1981.8,000 June 1, 1982 .8,000 June 1, 1983.8,500 June 1, 1984.10,000 June 1, 1985.11,000 June 1, 1986.11,000 June 1, 1987.12,000 June 1, 1988.12,000 June 1, 1989.12,000 June 1, 1990.145,000 Moreover, only the following methods shall be considered : (1) Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2517 2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde il courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 uns pour une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 uns.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre prtie ù terme fixe 20 ans.0° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et 0°, les obligations échéant à terme fixe 20 uns ne devront pas être pour un montant inférieur à $18,000 et si supérieur n ce dernier montant, cette pnrtic devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels en-licrs, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas (les exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er juin 1990 uu montant dc 8145,000 comprend un solde de $132,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans, et échéant comme suit: Annie Capital 1er juin 1991.8 9,000 1er juin 1992.10,000 1er juin 1993.10,000 1er juin 1994.12,000 1er juin 1995.12.000 1er juin 1996.13,000 1er juin 1997.15,000 lcrjuinl99S.16.000 1er juin 1999.17.000 1er juin 2000.18,000 L'adjudicntaire s'enguge n payer les obligations, cupitnl et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable nu pair ù Pointe-Gatineau.Le capital et les intérêts sont payables ù toutes les succursales dans lu province dc Québec de lu bnnquc dont le nom est mentionné dans ln procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de Indite banque ù Toronto, Onturio.Lesdites obligutions ne seront pus ruchctablcs par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 uns, pour un montant égul ou moindre de 8145,000.Toutefois, si elles sont émises en pnrtic ù terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8145,000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, uu pair, lc 1er juin dc chaque année ixnir le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de rémission, conformément aux tableaux d'échéance dc rémission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.(2) Ten-year serial bonds with the balance for 20-year fixed-term.(3) Ten-year serial bonds with the balance for 5-year short-term.(4) Ten-year serial bonds with the balance partly for 10-year short-term and partly for 20-year fixed-term.(5) Ten-year serial bonds with the balance partly for 5-year short-term and partly for 20-year fixed term.(0) Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-ycar fixed-term for the other part.However, in the case of paragraph- 4, 5 and 6, 20-year fixed-term bonds shall be for an amount not less than 818,000, and, if higher than this latter amount, the said part shall comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, five-year or 10-year short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, starting by the last years of maturities excluding the 20-ycar fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The June 1, 1990 maturity in the amount of 8145,000 comprises a balance of 8132,000, renewable for an additional 10-year period, and maturing as follows: Year Capital June 1, 1991.$ 9,000 June 1,1992.10,000 June 1, 1993.10,000 June 1,1994.12,000 June 1, 1995.12,000 June 1, 1996.13,000 June 1, 1997.15,000 June 1, 1998.16,000 June 1,1999.17,000 June 1,2000.18,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Pointc-Gatincau.Capital und interest urc payable at all brunches in the province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and for 20-ycar fixed-term for an amount equal to or less than $145,000.However, if they arc issued partly for 20-ycar fixed-term for an amount greater than 8145,000, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, ut par, on June 1st of each year, for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Each lender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of t lie tender. 2518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, «° 17 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 396 \u2014 $35,000 \u2014 achat d'un camion i\\ incendie; 404 \u2014 $225,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, etc.; 410 \u2014 $13,500 \u2014 aqueduc, égouts; 415 \u2014 $17,500 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 13 mai 1970, ii 8 heures du soir.Hôtel de ville, 12, avenue Picardie, Touraine, comté dc Gatineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Touraine (Comté de Gatineau), ce 15 avril 1970.Le secrétaire-trésorier, RÉJEAN Hl'I'K.Hôtel de ville, 12, avenue Picardie, Touraine, comté dc Gatineau, P.Q., Téléphone: 771-5668, code 819.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 396 \u2014 $35,000 \u2014 purchase of a fire truck; 404 \u2014 $225,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, etc.; 410 \u2014 $13,500 \u2014 aqueduct, sewers; 415 \u2014 $17,500 \u2014 aqueduct, sewers.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, May 13, 1970, at 8:00 o'clock p.m., in the Town Hall, 12 Picardie Ave, Touraine, county of Gutineau, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Touraine (County of Gatineau), April 15, 1970.Rejkan II .Secretary-Treasurer.34258-0 Town Hall, 12 Picardie Ave., Touraine, county of Gatineau, P.Q., Telephone: 771-5668, code 819.3425s Ventes pour taxes Sales for Taxes Municipalité du Comité dc Sherbrooke Avis est par le présent donné par Norbert Au-det secrétaire-trésorier dc la municipalité du comté de Sherbrooke, que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique, à l'Hôtel de ville de Sherbrooke, P.O., où lc Conseil dc comté tient ses sessions, JKIJDI le ONZIÈME jour de JUIN 1970, à DIX heures dc l'avant-midi, pour non-paiement des taxes dues et les frais encourus, à moins que le tout ne soit payé avant la vente.Municipality of the County of Sherbrooke Notice is hereby given by Norbert Audel.Secretary-Treasurer of the municipality of the county of Sherbrooke, that the immovables hereafter mentioned will lie sold by public auction, at the City Hall of Sherbrooke, P.Q., where the council of the countv holds its sessions, on THURSDAY, the ELEVENTH day of JUNK.1970, at TEN o'clock in the morning for the nonpayment of taxes due and the costs incurred, unless I he whole is paid licforc the sale Corporation municipue du cMlton d'Orfor.I \u2014 Muuiuipil Corporation of tlio township of Orford Propriétaire Proprietor Richard Bullnrd.Clifford Bussoll.Hnrvev Catohpaw J.N.Roger Côté.Marcel I) in mi .Gérard Duford.Sticc.-est.Philippe Doyon J.P.& Laurent Dufresne Neil Hansen.Juhani Lmik&o.Hubert Hutchins.Edwin C.McKclvey.Frank Monroe.Georges Morgan.A.Hoy id.Hi me: Hueine.Kernimd Gagnon.Yvon Stereky.Patrick Mulfins.Roger I'lament.Douai Benuchesnc.Ludger Croteau.Robert Chartier.( 1 astoii Larochelle.Gérald Robidos.Mme-Mrs.Henri Baron .Succ.-est.Oscar C.Miller Lots P.1075.P.849.P.008.815-1.P.1074.814-29.830-836-715.951-1004.P.10S0.P.793.P.1074.P.937-945.946.P.852.P.1074.P.1074.P.789.P.1013-1016 1017.838-9-11-19 837-4-11-17-18 P.1009-A.P.1074.P.814-29.P.908.P.908.P.968.908-148-151.908-78.968-152.818.i ; .nie Range 18.14.15.14.18.14.13-14.15-10.18.14.18.15.14.18.18.14.17.14.17.18.14.10.10.10.10.10.16.14.Tuxes iiuin.Mun.taxes 53.20 14.21 50.76 38.11 43.99 34.80 43.55 59.97 61.12 129.69 86.30 7.80 01.32 02.00 167.09 39.65 2.40 6.40 4.20 6.40 0.40 2.40 0.40 Tuxes Beol.School taxes 120.80 00.73 13,00 68.30 34.80 39 20 39.12 41.85 145! 05 46.09 277.28 25.88 78.84 21.23 168.42 14.31 14.31 5.40 6.40 70.20 11.31 Intérêt Interest\tTotal S S.24\t8 182.26 1.35\t08.68 1.33\t28.51 0.88\t126.(HI 2.33\t75.30 2.0-1\t85.83 4.04\t78.62 2.76\t88.10 2.10\t02.13 9.51\t210.2N 2.85\t48.91 14.36\t421.33 2.81\t89.11 1.44\t35.12 4.00\t144.16 2.79\t05.39 7.70\t174.79 1.76\t22.9» 10.90\t218.97 0.80\t17.51 1.88\t22.59 1.06\t10.66 1.23\t13.(M 1.97\t72.17 1.08\t7.48 0.80\t17.51 1.08\t7.48 QUÉBEC.OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2519 Municipalité de Saint-Élie d'Orford \u2014 Municipality of Snint-Élie of Orford Propriétaire Proprietor\tLots\tRang Rnnge\tTaxes mun.Mini.taxes\tTaxes scol.School tnxea\tIntérêt Interest\tTotal \t709-5.\t12.\tS 40.75 19.30 5.50 15.75\t\t1 3.76 8.43 4.35 8.59 1.66\tS 50.51 120.23 37.35 103.09 44.77 \t300-198 à-to 209 incl.306-131 it-to 134 306-58-59-65-66-67-68-69-89-90.705-1,705-2.\t6.0.6.B.\t\tS 92.50 27.50 78.75 43.11\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité du village de Compton \u2014 Municipality of the village of Compton\t\t\t\t\t\t \tP.29, 30.\t6.\tS 168.00\tS 212.02\tS 14.72\tS 394.74 Municipalité du canton d'Ascot \u2014 Municipality of the township of Ascot Auto lav Belvedere Inc., Joseph Bilodeau.Robert Boisvert.Mine-Mrs.Marcel Hébert Réal Pinard.Placements Culiisca Inc., Benjamin Wheeler.lean-Claude Noiseaux Mme-Mrs.Yvon (Prudence) ISelisle Club de Golf Belvedere Inc.Pine.Immobiliers de l'Est Inc.Jeun Gagné.Roger Bruneau.14G, 139.140, 198.10DT.10A, 232, 233.10A.319, 320.321, 140, 147 10A, 149, 150.10A, 94.P.t.!I.10A, 310 i\\-to 318 incl.et-uud 334.140,1,2,47.48 P.7B.P.9A.10A, 34 il-to 52 incl.65:\\-to 70 incl.4-15.VII.V.VIII.VIII.VIII.VIII.IX.VIII.VII.VIII.IX.VIII.IX.11.00 0.09 0.10 28.30 7.25 13.80 48.48 9.00 28.50 111.25 0.00 31.90 32.45 115.53 14.71 13.57 198.66 66.72 903.47 101.37 259.12 49.00 11.00 37.99 38.55 143.83 21.96 27.37 48.48 207.66 95.32 1.014.72 101.37 259.12 55.66 Municipalité d'Ascot Nord \u2014 Municipality of Ascot North Normand Blah*., Normand Blnis.Lucien Pelletier.Lucien Pelletier.Lucien Pelletier.Lucien Pelletier.Lucien Pelletjer.Lucien Pelletier.Lucien Pelletier.Louis Charret.Roland Thélierge.Mme-Mrs.Normand Kilteau Normand Oucllet.Normand Oucllet.Normand Ouellet.Normnnd Oucllet.Normand Ouellet.Normnnd Ouellet.Normnnd Ouellet.Normnnd Ouellet.Normnnd Ouellet.Normnnd Ouellet.Fernand Roy.Snvnrd Automobile.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Puul Leblond.Léo-Pnul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Puul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Pnul Ixiblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Paul Leblond.Léo-Puul Leblond.Léo-Paul Leblond.20C-12S.20C-129.20C-145.20C-140.200-147.20C-148.20C-149.200-150.20C-151,.21C-97.'.P.24-124.P.24-124 23C-138.23C-139.23C-140.23C-141.23C-142.23C-143.23C-144.23C-145.23C-140.23C-147.25A-2.20C-122.\u2022 23C-108.23C-109.23C-110.23C-U1.23C-112.23C-113.23C-U4.23C-115.23C-110.23C-117.23C-118.23C-119.23C-120.23C-121.23C-122.23C-123.23C-148.230-149.230-150.230-151.230-152.23C-153.230-154.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.8.8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.0.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4_____ 4.4.4.4.4.4_____ 4_____ 4.4.1.87 1.88 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.20 19.97 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 134.18 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.80 0.80 20.99 20.50 20.50 22.41 10.66 20.50 20.50 11.24 39.86 8.84 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3! 22 3.22 3.22 3.22 3.22 241.05 4.03 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3 22 3] 22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3^22 3.22 3.22 3.22 3.22 0 0 6 6 5 4 4 5 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .35 .35 .90 .50 .50 .56 .20 .20 .26 .63 .06 .08 .72 .60 .60 .60 .00 .60 .00 .60 .00 .00 .00 .10 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 3.02 3.03 29.39 27.50 27.50 28.47 22.42 27.26 27.26 19.13 40.92 32.89 5.44 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 405.23 7.03 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 2520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2b avril 1970, 102' année, n\" 17 Municipalité d'Ascot Nord (suite) \u2014 Municipality of Ascot North (continued) \t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Propriétaire\t\tRung\tmun.\tscol.\tIntérêt\tTotal \tLots\t\t\t\t\t Proprietor\t\tRnnge\tMun.\tSchool\tInterest\t \t\t\ttaxes\ttaxes\t\t \t\t4.\t$ 1.50\t$ 3.22\t$ 0.59\t$ 5.31 \t23C-150.\t4\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 \t23C-157.\t4.\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 \t23C-158.\t4\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 \t23C-159.\t4,\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 \t23C-100.\t4\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 \t23C161.\t4.\t1.50\t3.22\t0.59\t5.31 Pnul-Kmile Allv\t\t8.\t2.25\t4.89\t1.13\t8.27 \t19C.\t6.\t\t81.24\t10.44\t91.ok \t22E-68.\t4.\t\t\t\t \t23B-14.\t4.\t2.25\t13.81\t3.23\t19.29 \t24-318.\t8.\t1,50\t9.18\t2.03\t13.31 \t24-325.\t8.\t0.75\t3.22\t0.70\t4.07 \t24-320.\t8.\t0.76\t3.22\t0.70\t4.07 \t20E-58.\t5.\t10.80\t0.80\t1.28\t18.88 \t1'.22E, 23B.\t4.\t30.70\t39.37\t7.07\t83.20 \tP.19A.\t4.\t140.26\t\t14.25\t154.50 \t19B-10.\t4.\t2.26\t\t0.32\t2.57 \t20C-40.\t4.\t7.89\t\t1.08\t8.97 \t\t\t\t\t\t Municipalité de Hock Forest \u2014 Municipality of Rock Forest Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.I'leusunt View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant V:ew Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Pleasant View Hotel.Abbé Roger Thibault.Mme-Mrs.Fleurette Levcsque.Arcadius Denis.Gilles Labrie.Léandre Fortin.Gordon Renaud.Ovide Morin.422-11.422-12.422-13.422-14.422-15.422-10.422-17.422-18.422-19.422-20.422-21.422-22.422-24 .422-20.422-27.422-43.422-44 .422-45.422-40.422-08.422-69.422-70.422-71.422-72.422-73.422-75.422-70.422-77.422-78.422-79.422-82.422-83.422-84.422-85.422-86.422-87.422-88.422 P.P.618.P.615.612-37, 38, 39.10C-11.10B-53.8A-1.169-48.Orford.XI, Ase XI, Ase XII, Asc 2.32\tS 8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2,32\t8.90 2.32\t5.75 2.32\tS.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.00 2.32\tS.00 2 32\t8.00 2.32\t8.90 2.32\t8.90 3.87\t14.87 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.90 2.32\t8.00 5.41\t15.9» 5.41\t15.09 5.41\t15.99 5.41\t15.99 5.41\t15.99 5.41\t15.99 5.41\t15.99 242.37\t790.33 121.73\t171.78 111.67\t230.62 302.74\t416.80 20.04\t68.12 75.28\t205.03 138.02\t230.37 527.42\t710.37 Frais à collecter pour Bruzeau, Lafontnine et Fec-teau.$82.60.Costs to collect for Brazeuu, teau.$82.00.Lafontaine Tnd Fee- Richard Waite.Albert Murchie.H.P.Duquette.Guy Laforest.11 iI ai re Béliveau.Paul-Emile Desnoyer Jean-Paul Fortier____ Jean-Paul Fortier Jean-Pnul Fortier., Jean-Paul Fortier Jean-Paul Fortier Jean-Pnul Fortier.Jean-Pnul Fortier.6-53.P.169.P.311.P.508., P.8D.P.166-28, 29.167-32-13.167-32-43.167-32-48.167-32-49.107-32-73.167-32-74.107-32-78.XIII.Asc X, Asc.3.75 286.43 7.58 9.26 34.79 460.99 109.30 19.10 82.44 19.82 23.24 287.80 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, So.17 2521 Municipalité dc Hock Forest (suite) Municipality of Rock Forest (.continued) Propriétaire Proprietor\tLots\tRuiik Range\tTaxes 1111111.Mun.taxes\tTuxes scol.School taxes\tIntérêt Interest\tTotal \t\t\t\t\t\t$ 100.78 109.78 54.26 109.78 204.28 150.28 118.78 118.78 141.28 70.00 141.71 70.39 141.28 109.78 141.28 109.78 141.28 147.27 109.78 109.78 109.78 105.2S 115.18 133.14 4.73 5.85 0.10 10.24 310.40 379.97 1635.52 147.01 460.43 118.76 43.44 86.08 17.28 9.65 9.65 \t157-32-85.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t107-32-95.\t\t\t\t\t \t107-32-15.\t\t$204.28 150.28 118.78 118.78 141.28 70.00 141.71\t\t\t C.I.Inc.\t107-32-18.\t\t\t\t\t \t100-32-19.\t\t\t\t\t CI.Inc.\t107-32-20.\t\t\t\t\t \t107-32-21.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t107-32-25.\t\t\t\t\t F.ntr.Mi.ni j.isitions, ainsi que les frais encourus pour et par la vente, à moins que ces taxes et autres impositions et dépens ne soient payés avant lu vente, à savoir: Bédard, succession Joseph:\u2014Lot numéro cent huit partie sud-ouest des plans et livre de renvois officiels du cadastre de la ville de Richmond.Bédard, succession Joseph:\u2014l.ot numéro cent quarante-deux |>artie sud-ouest des plans et livre de renvois officiels du cadastre dc la ville de Richmond.$6.84.Donné n Richmond, ce 13c jour d'avril, 1970.Le sécréta ire-trésorier, 34171-16-2-0 Gilles Duciiaumk.Town of Richmond Notice is hereby given by the undersigned Secretary-Treasurer of the town of Richmond that the following property hereafter designated and situated within the limits of the town of Richmond will be sold by public auction at the office of the council, at the Town Hall in the said town of Richmond the FOURTEENTH day of the month of MAY 1970, at TEN o'clock in the forenoon, (advanced time) to satisfy the payment of the municipal taxes and other impositions and costs incurred by the sale unless these taxes and other impositions and costs !>e paid In-fore the sale, to wit: Bédard, estate Joseph:\u2014Lot number one hundred and eight southwest part on the cadastral plan and book of references for the town of Richmond.Bédard, estate Joseph:\u2014I«ot number one hundred forty-two southwest part on the cadastral plan and book of references for the town of Richmond.$6.84.Given at Richmond, this 13th day of April, 1970.Gilles Ducuarub, 34171-16-2-0 Secretary-Treasurer. 2522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 Ci lé de Shawinigan Avis est par les présentes donné que les propriétés immobilières ci-dessous décrites seront vendues à l'enchère publique, à la salle du conseil de l'Hôtel dc Ville, avenue des Cèdres, Shawinigan, JEUDI, lc VINGT ET UNIÈME jour du mois dc MAI 1970, à DEUX heures dc l'après-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales, avec intérêts, plus les frais encour-rus ou qui pourraient être encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.City of Shawinigan \u2022 Notice is hereby given that the immovable properties described hereunder, situated in the City of Shawinigan, will be sold by public auction in the council hall of the City of Shawinigan, on THURSDAY, the TWENTY-FIRST day of the month of MAY, 1970, at TWO o'clock of the afternoon, to satisfy the payment of the municipal taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before sale.Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivision Mme-Mrs.Ernest Lachance.Mine-Mrs.Bruno Tliiffeuult .Mine-Mrs.Conrad Lufontuiiic Lauréat Rousseau.Mme-Mrs.Albert Cloutier.Mine-Mrs.Jos.Eugene St-Onge Gérard Gauthier.La i un i lu- & Lefebvre.Louis-Georges Gauthier.Académie Carol.Onil Marineuu Roger Hébert .Bruno Pellcrin l Hivier Gélinas René Héroux.Mme-Mrs, Hormidns .lean Aimé Botirnivnl.Marcel Hnmelin Albert Allant.Clément Milot.Succession-Estate Donat Marchand.( jyprien Sauvageau.Hervé Chaîné.024.024.020.024.42.42.025.025.025.025.025.025.025 31.31.31.31.52.52.44.40.40.014.014.33.014 015.104.194.P.57 57.P.71 71 .29.P.47 P.49 49.49.49.49.49.49.49.49.49.49.49.49.49 49 49 49 P.27 53.10S.P.171.00.1'.320.P.80.87.201 202 P.025.I'.273.272.271.27(1.P.29.P.14.P.17.79.80.70.75.1.2, P.52.29.Kit.100.114.115.14.P.013.30.35.P.55.2.7.0-2.07.OS.70.71.72.73.12».130.177.09.80.20.25.24.10.139.62.Les propriétés immobilières susdites sont du cadastre officiel de la puroisse dc Stc-Flore et situées dans la Cité de Shawinigan.Donné à Shawinigan, ce 16c jour du mois d'avril en l'année 1970.Conditions: Comptant.Le greffier, 34175-17-2-0 Y von Boisvert.The above immovable pn>i>erties arc on the plan and in the book of reference of the parish of Ste-Flore and situated in the City of Shawinigan.Given at Shawinigan, this 16th day of April, 1970.Conditions: cash Yvoïi Boisvertj 34175 17-2-0 City Clerk: QUÉBEC OFFICIAT.GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2523 Ville dc Matanc Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la ville de Ma-tane, que les propriétés ci-dessous désignées et situées dans les limites dc la ville de Matanc, seront vendues à l'enchère publique, à l'hôtel «le ville dc Matanc, lc VINGTIEME jour du mois dc MAI 1970, ù DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires et autres impositions, ainsi que pour payer les frais encourus pour et par la vente, à moins que ces taxes et autres impositions et dépensa ne soient payés avant la vente, à savoir: Hou lay, Gérard.\u2014 Subdivision sept du lot deux cent un (201-7) des plans et livres de renvoi officiels du cadastre dc la paroisse dc St-Jérômc dc Matanc, ville dc Matanc.Taxes municipales: 89.50.Total: 9.50.Dionne & Fils Limitée.\u2014 Subdivision vingt et un du lot cent quatre-vingt-sept (187-21) subdivision vingt-deux du lot cent quatre-vingt-sept (187-22) des plans et livres dc renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jérôme de Matanc, ville de Matanc.Taxes municipales: $303.06.Total: S303.06.Fortin, Roland.\u2014 Subdivision soixante-huit du lot cent quatre-vingt-onze (191-68) des plans et livres dc renvoi officiels du cadastre dc la paroisse de St-.Iérômc dc Matanc, ville de Matanc.Taxes municipales: $240.36.Taxes scolaires: $201.66.Total: $442.02.Grant, Jimmy (Suce).\u2014 Subdivision cinq du lot (jeux cent quatre-vingt-seize (296-5) des plans et livres de renvoi officiels du cadastre dc la paroisse dc St-Jérômc dc Matanc, ville de Matanc.Taxes municipales: $4.51; taxes scolaires: $9.80.Total: $14.31.Labrie, Mme Arthur & Richard.\u2014Subdivision sept du lot cent quatre-vingt-deux (182-7) subdivision quarante-huit du lot cent cinquante-sept (157-48) des plans et livres de renvoi officiels du cadastre dc la paroisse de St-Jérômc dc Matanc, ville dc Matanc.Taxes municipales: $1,483.52; taxes scolaires: $2,205.Total: $3,688.52.Michaud, Richard.\u2014 Subdivision cinquante-deux du lot quatre-vingt-dix (90-52) des plans et livres dc renvoi officiels du cadastre dc la paroisse de St-Jérômc dc Matanc, ville de Matanc.Taxes municipales: $181.89; taxes scolaires: $96.78.Total: $278.67.Vézina, Edgar.\u2014 Subdivision deux dc la subdivision cent quarante du lot cent cinquante-sept (157-140-2) des plans et livres de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jérômc dc Matanc, ville dc Matanc.Taxes municipales: $322.19; taxes scolaires: $159.44.Total: $481.63.Donné à Matanc, ce 20c jour du mois d'avril 1970.Le secrflaire-lrcsorier, 34262-17-2-0 Olivier Philibert.Town of Matanc Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the town of Matanc, that the properties hereinafter designated and situated within the limits of the town of Matane, will be sold by public auction in the Matanc Town Hall, on the TWENTIETH day of the month of MAY, 1970, at TEN o'clock in the forenoon, for non-payment of municipal and school taxes and other dues, as well as to pay the costs incurred for and by the sale, unless the said taxes and other dues and expenses be paid before the sale, to wit: Houlay, Gérard.\u2014 Subdivision seven of lot two hundred and one (201-7) on the official plans and in the books of reference of the cadastre of the parish of St-Jérôme de Matanc, town of Matanc.Municipal taxes: $9.50.Total: $9.50.Dionne & Fils Limitée.\u2014 Subdivision twenty-one of lot one hundred and eighty-seven (187-21), subdivision twenty-two of lot one hundred ami eighty-seven (187-22) on the official plans and in the books of reference of the cadastre of the parish of St-Jérôme de Matanc, town of Matanc.Municipal taxes: $303.06.Total: $303.06.Fortin, Roland.\u2014 Subdivision sixty-eight of lot one hundred and ninety-one (191-68) on the official plans and in the books of reference of the cadastre of the parish of St-Jérômc de Matanc, town of Matanc.Municipal taxes: $240.36; school taxes: $201.66.Total: $442.02.Grant, Jimmy (Estate).\u2014 Subdivision five of lot two hundred and ninety-six (296-5) on the official plans and in the books of reference of the cadastre of the parish of St-Jérômc de Matanc.town of Matanc.Municipal taxes: $4.51; school taxes: $9.80.Total: $14.31.Labrie, Mrs.Arthur & Richard.\u2014 Subdivision seven of lot one hundred and eighty-two (182-7), subdivision forty-eight of lot one hundred and fifty-seven (157-48) on the official plans and in the books of reference of the parish of St-Jérômc île Matane, town of Matanc.Municipal taxes: $1,483.52; school taxes: $2,205.Total: $3,688.52.Michaud, Richard.\u2014 Subdivision fifty-two of lot ninety (90-52) on the official plans and in the books of reference of the parish of St-Jérôïne de Matanc, town of Matanc.Municipal taxes: $181.89; school taxes: $96.78.Total: $278.67.Vézina, Edgar.\u2014 Subdivision two of subdivision one hundred and forty of lot one hundred and fifty-seven (157-140-2) on the official plans and in the books of reference of the cadastre of the parish of St-Jérômc de Matanc, town of Matanc.Municipal taxes: $322.19; school taxes: $159.44.Total: $481.63.Given at Matanc, this 20th day of the month of April, 1970.Olivier Philibert, 34262-17-2 Secretary-Treasurer.Ministère des\tDepartment of Affaires municipales\tMunicipal Affairs Canada, Province dc HUGUES LAPOINTE Québec.|L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce «le Dieu, Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses uutres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada und her other Reulms and Territories, Queen.Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner, S a lut.Lcltrcs patentes Attendu que chacun des conseils municipaux de la cité dc Saint-Jean et dc la paroisse dc Sam i Jcan-l'Évangéliste, comté dc Saint-Jean, a adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil lc priant «l'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité dc la Loi dc la fusion volontaire des municipalités; Attendu epic les publications requises par l'article 6 de la loi précitée ont été faites; Attendu qu'un exemplaire dc la requête conjointe a été transmis nu ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale de Québec; Attendu «pi'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale de Québec et que cette dernière n'a pas tenu d'audition publique; Attendu qu'il y a lieu dc donner suite à la requête conjointe; A ces causes, du consentement et de l'uvis de Xotre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant lc numéro 104G, en date du 11 mars 1970, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons que des lettres patentes soient octroyées, fusionnunt la cité de Saint-Jean et la paroisse de Saint-Jcan-l'Evangélistc, comté dc Saint-Jean, et créant une nouvelle municipalité dc ville, sous le nom de « Ville de Saint-Jean aux conditions mentionnées duns la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Lc nom dc la nouvelle municipalité est « Ville de Saint-Jean » ; 2.Ia; territoire dc lu nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère îles Terres et Forêts le 9 décembre 1969; cette description apparaît dans la première annexe dudit arrêté; 3.La Loi îles cités et villes régira la nouvelle municipalité sous réserve des conditions dc la fusion telles qu'énoncées aux présentes; 4.Ia\\s dispositions législatives suivantes s'appliqueront à la nouvelle municipalité (deuxième annexe) : a) Ixs articles 490, 491 et 5S5 du chapitre 71 des lois de 1890 (lrc session); b) l'article 5 îles lois dc 1919-1920, chapitre e) lc chapitre 74 des lois dc 1953-1954; d) les article 6 et 7 des lois de 1955-1956, chapitre 82; c) le chapitre 49 des lois de 195S-1959; /) les articles 15, 17 et 21 des lois de 1958-1959, chapitre 58; g) l'article 13 des lois dc 1963 (Ire session), chapitre 82; h) le chapitre 82 «les lois dc 1964.5.La première élection générale île la nouvelle municipalité aura lieu le premier dimanche dc novembre 1970; cette élection et les subséquentes seront tenues conformément aux dispositions dc la Loi des cités et villes, et lc territoire de la nouvelle municipalité ne constituera qu'un seul quartier; 6.La liste des électeurs sera confectionnée en temps utile |xnir lu première élection générale conformément ù lu Loi des cités et villes; To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Letters Patent Whereas each of the municipal Councils of the city of Saint John's and of the parish of Saint-Jean-1'Évangélistc, county of Saint John's, adopted, by the absolute majority of its members, a by-law authorizing the presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in Council, asking him to grant letters patent amalgamating these said municipalities and creating a new municipality under the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act; Whereas the publications required by section 6 of the aforementioned Act have been made; Whereas a copy of the joint petition has been sent to the Minister of Municipal Affairs and to the Québec Municipal Commission; Whereas no request for an inquiry has been made to the Québec Municipal Commission, and that the latter bus no held a public hearing; Whereas it is expedient to accede to this joint petition; Therefore, with the consent ami advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 1016, dated March 11, 1970, Wc have decreed and ordered, and do hereby decree and order thut letters patent be granted, amalgamating the city of Saint John's and the parish of Saint-Jcan-l'Evangélistc, county of Saint John's, and creating a new city municipality, under the name of \"City of Saint John's\" under the conditions mentioned in the joint petition.The conditions arc as follows: 1.The name of the new municipality is \"City of Saint John's\"; 2.The territory of the new municipality is that officially described by the Department of Lnnds and Forests on December 9, 1969; the said description appears in the first appendix to the said Order; 3.The Cities and Towns Act shall govern the new municipality under reservation of the conditions for the amalgamation us set forth in these presents; 4.The following legislative provisions shall apply to the new municipality (second appendix): (a) sections 490, 491 and 585 of chapter 71 oî the Statutes of 1890 (1st Session); (b) section 5 of the Statutes of 1919-1920, chapter 91 ; (c) chanter 74 of the Statutes of 1953-1954; (d) sections 6 and 7 of the Statutes of 1955-1956, chapter 82; (e) chnptcr 49 of the Statutes of 1958-1959; (/) section 15, 17 and 21 of the Statutes of 1958-1959, chapter 58; (g) section 13 of the Statutes of 1963 (1st session), chapter 82; (k) chapter 82 of the Statutes of 1964.5.The first general election in the new municipality shall take place on the first Sunday of November, 1970; it and subsequent elections shall be held pursuant to the provisions of the Cities and Towns Act, and the territory of the new municipality shall comprise only one ward; 6.The electoral list shall be drawn up in time for the first general election pursuant to the Cities und Towns Act; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April SB, 1970, Vol.10S, No.17 2525 7.Jusqu'à la première élection générale, le conseil qui a le pouvoir «l'administrer la nouvelle municipalité sera composé dc dix (10) membres, soit lc maire actuel de la cité dc Saint-Jean qui «leviendra lc maire dc In nouvelle municipalité, les six (6) conseillers dc la cité de Saint-Jean en fonction au moment de l'adoption du règlement No 914 et trois (3) des membres «lu conseil dc la corporation municipale dc la paroisse de Saint-Jcan-l'Évangéliste, en fonction, au moment dc l'adoption du règlement No 125.Les nominations des trois (3) représentants de la corporation municipale dc la paroisse dc Saint-Jcan-l'Évangéliste devront être faites par résolution de son conseil municipal dans les trente (30) jours cjni suivent l'adoption du règlement No 125.Si les nominations au conseil provisoire n'ont pas été ainsi faites, lc ministre des Affaires municipales déterminera la procédure à suivre pour remplir ces charges.Toute vacance tlans le conseil provisoire est remplie par résolution du conseil provisoire en nommant une personne eligible de l'ancienne municipalité représentée par le titulaire dont la charge est devenue vacante; 8.La première séance générale du conseil provisoire dc la nouvelle municipalité aura lieu le deuxième lundi suivant la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Cette séance se tient dans la salle de l'Hôtel de Ville dc Saint-Jean, à huit (8) heures du soir et sans autre convocation; 9.Si la séance n'a pas été ainsi tenue, le ministre des Affaires municipales en fixe la date, lc lieu et le mode «le convocation; 10.lies fonctionnaires et employés de la cité de Saïui -.lean demeurent au service dc la nouvelle municipalité, au même titre, sans diminution dc traitement ou de salaire jusqu'à leur démission ou jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par le conseil.Les employés et fonctionnaires dc lu corporation municipale «le la paroisse de Saint-Jcan-l'Évangéliste demeureront au service de la nouvelle municipalité dans les fonctions qui leur seront attribuées par le conseil, sans diminution de traitement ou de salaire; 11.A compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes, l'intérêt sur les arrérages de taxes et autres redevances dc l'année 1970 sera de 8J{>% l'an jusqu'à modification par le conseil; 12.Le conseil permanent se compose d'un maire et de six (6) conseillers élus selon la loi; les sièges des conseillers seront numérotés dc un (1) à six (6); 13.La fusion des deux municipalités requérantes est faite aux conditions suivantes: A) Dette: a) Toutes les dettes existantes dans les municipalités de Saint-Jcan-l'Évangéliste et de la cité dc Saint-Jean au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes deviendront n lu charge de lu nouvelle ville dc Saint-Jean; b) Les répartitions spéciales décrétées et imposées par les règlements dc la cité «le Saint-Jean seront perçues par la nouvelle ville dc Saint-Jean, aux mêmes conditions; c) Les règlements 80, 87, 94, 102 et 110 dc la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean-l'Évangéliste sont remplacés par les dispositions suivantes: 7.Until the first general election, the Council which has the power to administer the new municipality shall be composed of ten (10) members, that is, the present mayor of the city of Saint John's who shall become the mayor of the new municipality, the six (6) Councillors of the city of Saint.John's in office when by-law No.914 is adopted, and three (3) members of the Council of the municipal corporation of the parish of Snint-Jcan-1'Évangélistc in office when by-law No.125 is adopted.The appointment of the three (3) representatives of the municipal corporation of the parish of Saint-Jean-1'Évangélistc shall be made by resolution of its municipal Council within thirty (30) days following the adoption of by-law No.125.If the appointments to the interim Council were not so made, the Minister of Municipal Affairs shall determine the procedure to lie followed to fill the posts.Any vacancy in the interim Council is filled by resolution of the interim Council by appointing thereto an eligible person from the former municipality represented by the person whose post has become vacant; 8.The first general meeting of the interim Council of the new municipality shall take place on the second Monday following the date on which the letters patent become effective.Such meeting shall be held in the hall of the Saint John's City Hall at eight (8) o'clock in the evening, without further convocation; 9.If the meeting is not so held, the Minister of Municipal Affairs shall fix the date, the place and the method of convocation thereof; 10.The civil servants and employees of the city of Saint John's shall remain in the service of the new municipality, with the same classification, without any «lecrease in wages or salary until their retirement or until the Council decides otherwise.Employees and civil servants of tlic municipal cor|x)ration of the parish of Saint-Jcan-l'Évangéliste shall remain in the service of the new municipality in the offices assigned to them by the Council, without any decrease in wages or salary; 11.From and after the date on which the hitters patent become effective, the interest on the arrears of taxes and other dues for the year 1970 shall be 8}4% per annum until amendment by the Council; 12.The permanent Council shall be composed of a mayor and six (6) Councillors elected according to law; the Councillors' scats shall be numbered from one (1) to six (6); 13.The amalgamation of the two petitioning municipalities shall be made under the following conditions; (A) Debt: (a) All existing debts in the municipalities of Saint-Jean-1'Évangélistc and the city of Saint John's when the letters patent become effective shall become the responsibility of the new city of Saint-John's; (b) Special assessments ordered and levied by by-laws of the city of Saint John's shall be collected by the new city of Saint-John's, under the same conditions; (c) By-laws 86, 87, 94, 102 and 110 of the municipal corporation of the parish of Saint-Jcan-1'Évangélistc are replaced by the following provisions: 2526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 avril 1970, 102' année, n° 17 1.Une taxe spéciale est imposée et sera prélevée sur toutes les propriétés longeant ou ayant front sur les rues, avenues, chemins ou boulevards desservis en vertu des règlements susmentionnées dc la façon suivante: Pour les travaux d'égout: un tiers pour chaque propriétaire riverain du coût réel des travaux équivalant à ceux requis pour un tuyau dc 24 pouces dc diamètre au maximum; 2.Quant à l'excédent du coût des travaux décrétés par lesdits règlements, une taxe spéciale est imposée et sera prélevée annuellement sur les biens-fonds imposables de la nouvelle ville dc Saint-Jean à un taux suffisant, d'après le rôle d'évaluation en vigueur chaque année, pour pourvoir nu paiement, en capital et intérêts, des échéances annuelles prévues aux tableaux dc remboursement décrits nuxdits règlements; 11) Evaluation: Les rôles d'évaluation seront normalisés au moment de l'émission des lettres patentes, en prenant comme base les chiffres fournis par la compagnie Sonarcx Ltée, dans le rapport du 28 août 1969; les normes d'évaluation seront celles qui étaient en vigueur dans la cité de Saint-Jean; C) Cour municipale: La juridiction dc l'ancienne Cour municipale dc la cité dc Saint-Jean est étendue à tout lc territoire de la nouvelle municipalité; D) Fonds de roulement et fonds industriel: Le fonds de roulement et lc fonds industriel de la cité de Saint-Jean pourront être utilisés en ce qui a trait à tout le territoire dc la nouvelle municipalité.Ex foi de quoi, Xous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau dc Notre province dc Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur dc Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville dc Québec, de Notre province de Québec, ce onzième jour dc mars en l'année mil neuf cent soixante-dix de l'ère chrétienne et de Notre Règne la dix-neuvième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Lucien Darveau.Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions dc l'article 13 dc la Loi de la fusion volontaire des municipalités.Le sous-ministre des affaires municipales, 34250-o Richard Beauliei .1.A special tax is imposed and shall be levied on all properties lying along or fronting on streets, avenues, roads or boulevards served, pursuant to the aforementioned by-laws, in the following way: For sewage works: a third for each riverain property of the real cost of the works equivalent to those required for a pipe of a maximum diameter of 24 inches; 2.With respect to the cost of the works ordered by the said by-laws, a special tax is imposed and shall be levied annually on taxable real estate of the new city of Saint John's at a rate sufficient, according to the valuation roll in force each year, to provide for the payment, both capital and interest, of the annual maturities contemplated in the tables of reimbursement described in the said by-laws; (B) Valuation: The valuation rolls shall be standardized upon the issuing of the letters patent, taking as a basis the numbers supplied by \"Sonarcx Ltée\" in the report dated August 28, 1969; the valuation standards shall be those which were in force in the city of Saint-John's; ((') Municipal Court: The jurisdiction of the former Municipal Court of the city of Saint John's is extended to the entire territory of the new municipality; (D) Working Capital and Industrial Fund: The working capital and industrial fund of the city of Saint John's may be used for anything related to the entire territory of the new municipality.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed.Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugoes Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.(iiven in Our Parliament Buildings, in Our city of Québec, in Our Province of Québec, this eleventh day of March, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy, and in the nineteenth year of Our Reign.By command, Lucien Darveau, Assistant Deputy Attorney General.Notice of the issuing of the above letters (latent is given pursuant to the provisions of section 13 of the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act.Richard Beauueu, 34250 Deputy M in ister of M un ici pal .Iffa irs.Régie des Marchés Agricoles du Québec Quebec Agricultural Marketing Board Plan conjoint des producteurs de lait de Québec-Sud Syndicat des producteurs de lait dc Québec-Sud, requérant.Décision Vu que lc mode de financement et lc montant de la contribution qui doit être versée par tous Joint Plan of Québec-South Milk Producers The Milk Producers' Syndicate of Quéliec South, petitioner.Decision Whereas the method of financing and the amount of the contribution which must be paid QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 86, 1970, Vol.102, No.17 2527 les producteurs vises par le plan conjoint des producteurs dc lait de Québec-Sud sont déterminés à la section XII dudit plan, publié dans la Gazelle officielle de Québec le 17 avril 1965, telle que modifiée par la décision No 722 rendue par la Itégie le 18 septembre 1968; Vu que le syndicat chargé d'appliquer ce plan conjoint et les producteurs réunis en assemblée générale ont adopté une résolution en vue de porter cette contribution dc deux cents et demi (0.025) à quatre cents (0.04) le cent (100) livres de lait livré à la fabrique; Vu que cette augmentation dc la contribution a été acceptée par les producteurs pour combler le déficit d'opération encouru par lc syndicat dans l'exécution du plan conjoint et particulièrement afin de participer ù un programme dc publicité des produits laitiers; Vu que pour ces motifs il y a lieu dc recevoir lu demande du syndicat requérant et d'approuver la résolution précitée; En conséquence, la Itégie des marchés agricoles du Quél>cc approuve la.résolution adoptée par le requérant, ainsi que par les producteurs visés par le plan conjoint des producteur.» de luit dc Québec-Sud réunis en assemblée générale, en vue de porter lc montant dc la contribution prévue pour l'administration du plan conjoint dc deux cents et demi (0.025) ù quutrc cents (0.04) lc cent livres (100) dc lait.Le deuxième alinéa de la section XII du plan conjoint précité est donc remplacé par lc suivant: « Lc montant de cette contribution est déterminé par le Syndicat au moyen d'une résolution qui doit être approuvée par lu Régie avant d'entrer en vigueur.Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une telle résolution, lu contribution est de quatre cents (0.04) le cent (100) livres de luit livré à une fabrique ».Québec, ce 14 avril 1970.Régie des marchés agricoles du Québec.Lc secrétaire, 34243-0 Cilles Le Blanc.Lc Plan conjoint des producteurs d'oeufs dc commotion du Québec Aris Vu que le règlement numéro 6 dc lu Fédération des Producteurs d'Oeufs de Consommation concernant la commercialisation et la mise en vente en commun des oeufs dc consommation dans lu province entre en vigueur ù lu dute déterminée par ladite Fédération; Vu que cette dernière avait fixée au 2 mars et, par la suite, uu 27 avril 1970, la mise en application de son règlement numéro 6.et que la Régie en a donné avis public: Vu que la Fédération a de nouveau décidé dc reporter la mise en application de ce règlement, et ce, au // mai 1970: Vu que la Fédération a adopté le règlement, numéro 6-A modifiant lc règlement numéro 6, et qu'ils doivent entrer en vigueur n lu même date; En conséquence, lu Régie des marchés agricoles donne avis que les règlements numéros 6 et 6-A, de la Fédération des Producteurs d'Oeufs de Consommation concernant In commercialisation et la mise en vente en commun des oeufs dans In Province entreront en vigueur le // mai 1970.Montréal, le 21 avril 1970.Régie des marchés agricoles du Quéliec.Ac secrétaire.34243-0 Gilles Le Blanc.by all producers mentioned by the joint plan of Quebec-South milk producers is determined in section XII of the said plan, published in the Québec Official Gazelle of April 17, 1965, as amended by decision No.722 rendered by the Board on September 18,1968; Whereas the Syndicate charged with the application of this joint plan and the producers grouped at a general meeting have adopted a resolution in order to bring this contribution of two cents and one-half (0.025) to four cents (0.04) per one hundred (100) pounds of milk delivered to a plant; Whereas this increase of contribution was accepted by the producers to fill the operation deficit incurred by the Syndicate in the execution of the joint plan and particularly in order to participate in a dairy product advertisement program; In view of these motives, it is expedient to grant the request of the petitioning syndicate and to approve the aforesaid resolution; Therefore, the Québec Agricultural Marketing Board approved the resolution adopted by the petitioner, as well as the producers mentioned in the joint plan of Quebec-South milk producers grouped at u general meeting, in order to bring the amount of the contribution provided for the administration of the joint plan two cents and one-half (0.025) to four cents (0.04) per one hundred pounds (100) of milk.The second paragraph of section XII of the aforesaid joint plan is then replaced by the following: \"The amount of this contribution is determined by the Syndicate through a resolution which must be approved by the Board before coming into force.Until it is amended by such a resolution, the contribution is of four cents (0.04) per one hundred (100) pounds of milk delivered to a plant\".Québec, April 14, 1970.Québec Agricultural Marketing Board.Gilles Le Blanc, 34243 Secretary.Kggs for Consumption Producers' Marketing Plan Notice Wheiieas, Regulation number 6 of the Federation of the Producers of eggs for consumption concerning the commercialization and the joint Marketing of eggs for consumption in the Province of Québec comes into force at the date determined by said Federation; Whereas, this latter has fixed on March 2nd and, thereafter on April 27, 1970, the application of its Regulation number 6, and that the Board has given public notice thereof; Whereas, the Federation has decided to postpone again the application of this Regulation until May 11th 1970: Whereas, the Federation has adopted Regulations number 6-A, modifying Regulation number 6 and that both must come into force on the same day; Consequently, the Québec Agricultural Marketing Board, hereby gives notice that Regulations No 6 and 6-A of the Federation of the Producers of Eggs for Consumption, concerning the commercialization and the joint marketing of eggs in the Province of Quéliec, will come into force on May 11th 1970.Montreal, April 21st, 1970.Québec Agricultural Marketing Board.Gilles Le Blanc, 34243-0 Secretary. 2528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n\" 17 Plan conjoint des producteurs dc luit nature dc la région du nord-ouest Québécois Syndicat des producteurs de lait nature dc lu région du Nord ouest québécois, requérant.Décision Vu que le 11 ii h ii- de financement et le montunt dc la contribution qui doit être versée par tous les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs dc lait nature dc la région du Nord-ouest québécois sont déterminés à la section XII dudit plan, publié dans la Gazelle officielle de Québec, du 27 janvier 1908, telle que modifiée pur la décision No 711 rendue pur lu Régie le 23 juillet 1908; Vu que le Syndical cburgé d'appliquer ce plan conjoint et les producteurs réunis en assemblée générale ont adopté une résolution en vue de porter cette contribution dc trois cents et demi (0.035) à cinq cents (0.05) le cent (100) livres de lait livré à une fabrique; Vu que cette augmentai ion de In contribution a été acceptée par les producteurs afin de participer à ud programme de publicité des produits laitiers; Vue que pour ces motifs il y u lieu dc recevoir la demnndc du syndicat requérant et d'approuver la résolution précitée; En conséquence, la Régie des marchés agricoles du Québec approuve la résolution adoptée par lc requérant, ainsi que pur les producteurs visés par lc plan conjoint des producteurs de lait nature dc la région du Nord-ouest québécois réunis en assemblée générale, en vue de porter le montant de la contribution prévue pour l'administration du plan conjoint dc trois cents et demi (0.035) il cinq cents (0.05) lc cent livres (100) dc lait.Le deuxième alinéa dc la section XII du plan conjoint précité est donc remplacé par le suivant : « Lc montant dc cette contribution est déterminé par le syndicat au moyen d'une résolution qui doit être approuvée pur lu Régie avant d'entrer en vigueur.Jusqu'il ce qu'elle soit modifiée par une telle résolution, lu contribution est dc cinq cents (0.05) le cent livres (100) de lait livré à une fabrique ».Québec, ce 14 avril 1970.Régie des marchés agricoles du Québec.Le secrétaire, 34243-0 Gilles Le Blanc.Plan conjoint des producteurs d'oeufs dc consommation du Québec Amendement au règlement concernant les quotas Prenez avis qu'en vertu dc l'article 48 de la Loi des marchés agricoles du Québec, et suite ù une requête déposée à cette fin par la Fédération des producteurs d'oeufs dc consommation, lu Régie des marchés agricoles du Quéliec a approuvé le règlement No l.\\ dc ladite Fédération modifiant le règlement No 1 concernant les quotas.Cé règlement, dont le texte suit, entre en vigueur dès la présente publication.Montréal, ce 17 avril 1970.Le secrétaire, Me Gilles Le Blanc.Règlement So IA modifiant le règlement No 1 concernant les quotas.1.L'article 16 est modifié en ajoutant les paragraphes suivants: Joint Plan of Raw Milk Producers of North-Western Québec Syndicat des producteurs dc lait nature de la région du Nord-ouest Québécois, petitioner.Decision Whereas the method of financing und the amount of the contribution which must be puid by all producers mentioned by the joint plan of raw milk producers of North-Western Québec is determined in section XII of the said plan, published in the Québec Official Gazette of January 27, 1968, as amended by Decision No.771 rendered by the Board on July 23, 1968; Whereas the Syndicate charged with the application of this joint plan und the producers grouped at a general meeting have adopted a resolution in order to bring this contribution of three ccnLs and one-half (0.035) to five cents (0.05) per one hundred pounds (100) of milk delivered to a plant ; Whereas this increase of contribution was accepted by the producers in order to participate in a dairy product advertising program: In view of these motives, it is expedient to grant the request of the petitioning syndicate and to approve the uforcsuid resolution; Therefore, the Québec Agricultural Marketing Hoard approved the resolution adopted by the petitioner, as well us the producers mentioned in the joint plan of raw milk producers of Northwestern Québec grouped at u general meeting, in order to bring the amount of the contribution provided for the administration of the joint pluu from three cents und onc-hulf (0.035) to five cents (0.05) per one hundred pounds (100) of milk.The second paragraph of section XII of the aforesaid joint plan is then replaced by the following: \"The amount of this contribution is determined by the Syndicate through a resolution which must be approved by the Board before coming into force.Until it is amended by such u resolution, the contribution is of five cents (0.05) per one hundred pounds (100) of milk delivered to a plant\".Québec, April 14, 1970.Québec Agricultural Marketing Board.Gilles Le Blanc, 34243 Secretary.Joint Plan of the Producers of Eggs for Consumption of Québec Amendment to regulations concerning quotas Take notice that, pursuant to section 48 of the Québec Agricultural Marketing Act and further to u petition filed for this purpose by the Federation of the Producers of Eggs for Consumption, the Québec Agricultural Murketing Hoard approved By-law No.1A of the said Federation, amending By-law No.1 concerning quotas.The said by-law, the text of which follows, shall come into force on the date of its publication.Montreal.April 17, 1970.Me Gilles Le Blanc, Secretary.Ily-laie No.IA amending By-law So.I concerning quotas 1.Article 16 is amended by adding the following paragraphs: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2529 h) Dans le cas du locataire d'une exploitation avicole, aux conditions suivantes: 1) que le quota ne soit émis que pour lu durée du bail; 2) qu'à l'expiration de son bail, le locataire ne puisse prétendre avoir détenu un quota pendant iu durée dc son bail dc façon à pouvoir faire une nouvelle demande de quota; 3) que le locateur de l'exploitation donnée à bail en soit le véritable propriétaire et qu'il soit lui-même détenteur d'un quota; 4) que le locateur renonce à tout ou partie de son quota en faveur de son locataire.i) Dans le cas d'un producteur qui, au 31 mars 1970, était propriétaire de pondeuses et qui en vendait la production directement aux consommateurs, un quota lui sera émis pour le nombre de (tondeuses dont il était propriétaire ii cette date, à la condition qu'li en fasse la demande ù lu Fédération et qu'il cesse de vendre la production dc ses pondeuses directement aux consommateurs.2.Le titre de la section 11 est remplacé pur le suivant: « Dispositions particulière* /xiur l'année 11170 > 3.L'article 19 est modifié en remplaçant les chiffres « 1909 » par « 1970 >\u2022 partout où ils se rencontrent duns cet article; 4.L'urticlc 20 est modifié en remplaçant duns la deuxième ligne les mots « 31 décembre 1908 » pur les mots « 31 décembre 1969 ».5.a) ix premier alinéa de l'article 21 est remplacé par le suivant : « L'augmentation prévue à l'article précédent est ai 11-dmée n lu catégorie suivante dc producteurs: les producteurs qui détiennent un quota île moins de 15,000 pondeuses.Toutefois, afin d'obtenir une augmentation dc quota, les producteurs qui détiennent un quotal dc moins dc 3.000 pondeuses doivent se prévaloir d'une augmentation suffisante pour atteindre uu quota minimum dc 3,000 pondeuses.Aucun producteur ne peut cependant obtenir une augmentation de quota supérieure à 5,000 pondeuses et le quota d'un producteur après augmentation ne peut excéder 15.000 pondeuses.» b) ix deuxième alinéa de l'article 21 est abrogé.c) ix troisième alinéa dc l'urticlc 21 est modifié en remplaçant les chiffres \u2022 1969 » pur « 1970 >.6.L'article 21A est ajouté après l'article 21 : 21A.Lu Fédération émettra un quota aux producteurs qui étuient propriétaires de pondeuses le 31 murs 1970, mais qui n'avaient pas de quota |k>ur ces pondeuses.L'émission du quota se fera aux conditions suivantes: 1) Que le producteur eu fusse lu demunde duns un délui de trois mois ù compter du 31 mars 1970.2) Que le quota total du producteur n'excède pas 15,000 pondeuses et ne soit pas inférieur à 1.0(H).3) Qu'advenant le eus où le producteur avait plus de 15,000 pondeuses, il se départisse de l'excédant avant d'obtenir son quota.4) Que le producteur signe tout document requis pur lu Fédération nvunt d'obtenir un quotu, incluant un affidavit attestant l'exactitude des faits qu'il déclare à lu Fédération; 5) Que le producteur uit payé à In Fédération toute somme qu'il lui doit en vertu dc lu loi, du Plun Conjoint ou des règlements.(h) In the case of a lease-holder of a poultry-keeping enterprise, on the following conditions: (1) The quota must be issued for the term of the lease only; (2) At the expiry of the lease, the lease-holder cannot claim that he held a quota during the term of the lease, for the purpose of making a new application for aquota; (3) The lessor of the enterprise being leased must be the true proprietor and he also must be the holder of a quota; (4) The lessor must renounce all or part of his quota in favour of his lease-holder.(i) In the case of a producer who, on March 31, 1970, was proprietor of laying birds and who sold their production directly to consumers, a quota shall be issued for the number of laying birds that he owned at that same date, providing that he apply for it to the Federation and that he no longer sell the production of his laying birds directly to consumers.2.The title of Section 11 is replaced by the following: \"Special provision* for 1970\" 3.Article 19 is amended by replacing everywhere in this article number \"1909\" bv number \"1970\".4.Article 20 is amended by replacing on the second line the words \"December 31.1968\" bv \"December 31, 1969\".5.(a) The first paragraph of article 21 is replaced by the following: \"The increase provided for in the preceding article is allotted to the following class of producers: the producers having a quota of less than 15,000 laying birds.However, in order to get u quota increase, the producers holding a quota of less than 3,000 laying birds must avail themselves of nn increase important enough to allow them to reach a minimum quota of 3,000 laying birds.No producer however can get an increase greater than 5,000 laying birds ami the producer's quota uftcr un increase shall not exceed 15,000 hiving birds.\" (b) The second paragraph of article 21 is cancelled.(c) The third paragraph of article 21 is amended bv replacing numlier \"1969\" by number \u20221970\".0.Article 21A is added after article 21 : 21 A.\"The Federation shall issue a quota to producers who, on March 31, 1970, owned laying birds but had no quota for them.A quota shall lie issued on the following conditions: 11 ) The producer must apply for it within three months after March 31.1970; (2) The total quota of a producer shall not exceed 15,000 laying birds and be of at least 1.000: (3) Should a producer have more than 15,000 hiving birds, he must get rid of the surplus before he can get his quota ; (4) Before be can get a quotu, a producer must sign any document required by the Federation, including an uffidavit certifying that the facts given the Federation are exact; (5) The producer must have puid the Federation any sum that he might have owed it under tlie provisions of the Act.the joint plan or the regulations. 2530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970.102' année, n\" 17 7.L'article 22 est modifié en remplaçant par les chiffres « 1970» les chiffres « 1909» partout où ils s'y rencontrent.8.L'article 24 est modifié en remplaçant par « 1970 » les chiffres « 1969 » dans la deuxième ligne de l'article.34243-o 7.Article 22 is amended by replacing everywhere in this article number \"1969\" by number \"1970\".8.Article 24 is amended by replacing on the second line number \"1969\" bv number \"1970\".34243 Ventes par Shérifs\tSheriffs' Sales AVIS PUBLIC, est pnr le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.\tPUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.G A S P É\tGASP Ë :ss Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Gaspé Division Iles dc la Madeleine Québec, C IDEAL S T AIN LES Cour Provinciale, J A STEEL INC., corpora-No 36-36S.\\ tion légalement constituée ' ayant une place d'affaires à 379, 25e rue Québec, district de Québec, demanderesse, r* GÉRARD LONGUÉPÉE, domicilié à Cap-aux-Mcules, Iles dc la Madeleine, district dc Gaspé, défendeur.Comme appartenant au défendeur: « Lc lot numéro quatre-cent deux (402) du cadastre officiel jxiur la paroisse de l'Ile dc Cap-aux-Mcules, municipalité de Fatimn, uyant une superficie de 92,900 p.c., avec bûtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement au Palais de Justice, Hâvre-Aubcrt, Iles de la Madeleine, le VENDREDI, VINGT-DEUXIÈME jour de MAI 1970 à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Napoléon Bkiano.Hâvre-Aulicrt, I.M.34242-o M O N T II fi A L (Erratum) Dans l'avis publié duns lu Gazette officielle du Québec, en date du 18 avril 1970, à la page 2382, nous aurions dû lire comme demanderesse: « The Prudential Insurance Co.of America » au lieu dc * The Prudential Insurance Co.of Canada ».Dans la cause Trust Général du Canada rs Philippe Labrosse publié à la page 2384 dc la même édition, nous aurions dû lire comme date de vente: « le VINGT-SIXIÈME jour de MAI 1970 » au lieu dc 1909.34259-o (TDEAL STAINLESS t,J 1 STEEL INC., a corpora- Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Gaspé Division of the Magdalen Islands Québec, Provincial Court, No.36-368.\\ tion legally incorporated having a place of business at 379, 25th Street, Quéliec, district of Québec, plaintiff, rs GÉRARD LONGUÉPÉE, domiciled ut Cap-aux-Mcules.Magdalen Islands, district of ( iaspé, defendant.As belonging to the defendant: \"Lot number four hundred and two (402) of the official cadastre for the parish of Ile de Cap-aux-Meules, municipality of Fatima, having un urea of 92,960 sq.ft.with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.\" To lie sold at the Registry Office, at the Court House, at Hâvre-Aubcrt, Magdalen Islands, on FRIDAY, the TWENTY-SECOND day of MAY, 1970, at ELEVEN o'clock in the morning.Sheriff's Office, Napoléon Bui and.Court House, Assistant Sheriff.Hftvre-Aubcrt, Mngdulcii Islands.34242 M O N T 11 E A L (Erratum) In the notice published in the Québec Official Gazette of April 18,1970, on page 2382, one should have read as plaintiff: \"The Prudcntiiil Insurance Co, of America\" instead of \"The Prudential Insurance Co.of Canada\".In the Trust General du Canada es Philippe Labrosse case published on page 2384 of the same edition, one should have read as the date of sale: \"the TWENTY-SIXTH dav of MAY.1970\" instead of 1909.34259 INDEX No 17 ARRÊTÉ en Conseil ORDER in Council 1558 \u2014 Régie des Rentes du Québec, Règlement.2485 1558 \u2014 Québec Pension Board, Regulations.2485 ASSEMBLÉE MEETING Aima & Jonquières Railway Company (The).2475 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 26, 1970, Vol.102, No.17 2531 ASSOCIATION coopérative COOPERATIVE Association Association coopérative immobilière de Maria (Dissolu!ion).2475 AVIS divers MISCELLANEOUS Notices Asbestos, ville \u2014\u2022 town (llue-Ruelles \u2014 Streets-Lanes).2498 Corporation des administrateurs agréés du Québec (La) (Règl.).25(j0 Corporation of chartered administrators of Québec (The) (By-laws).2500 Estate of Mrs.Beatrice Meunier Pilottc (Benefit of Inventory).2498 Succession dame Béatrice Meunier Pilotte (Bénéfice d'inventaire).2498 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: A pplications: Bernier, Joseph-Émile-Roméo (dit Robert E.Bernier).2488 Carrouset, Jean.2480 Crawanciuk, Edward David.2487 Gagné, Jules.2486 Hamclin, Leopold.2486 Honing, Joseph.2480 Juskovic, Ladislav.2487 Krajewski, Henry George.2487 Landriault, Claudette.\u2022.2487 Ostrovsky, Harry.2486 Ostrovsky, Martin George.2487 Papageorgakopoulos, Constantinos.2486 CHANGEMENT DE NOM Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Boucher, Yvon.2488 Dodd, Joseph Marcel Guy.2488 Hart, Stephen.2488 Napier, Joseph Francis.2488 SAVINGS and credit unions CAISSES d'épargne et de crédit Caisse populaire St-Pie X dc Laval (Nom-Name ch.).2500 Sol-Mark Printing Ltd.2481 Ungava Power Company.2482 Ville Marie Paper Box Co.Ltd.2480 Dissoutes Dissolved COMMISSION QUEBEC Municipale Municipal du Quéliec Commission Pointe-aux-Tremblcs, cité-city (Plus tutelle-no longer in default).2490 COMPAGNIES Avis relatifs il la loi des COMPANIES Notices relative to the Act of Licensed to do Business Autorisées ù faire des affaires Canadex Mining Corporation Limited.2490 Consolidated Hydrocarbons Limited.2490 Early Bird Mines Ltd.2489 Image Systems, Inc.2489 Mazda Motors of Canada Ltd.24S9 Signal Oil and Gas Company of Cunudu.Ltd.24S9 Charles demandes d'abandon de Charters \u2014 .tpplications for Surrender of Distribiteur Laviolette inc.2481 Ell Clothing Contracting Inc.2481 P.&T.Cleaners Ltd.:.2481 Fornard Development Corporation.2482 Garage Henri Thibault inc.2480 I.B.Cosmetics Inc.2481 Journal le Carabin inc.(Le).2482 Knit Craft Mills Ltd.2480 Montreal Circle Ltd.(The).2480 Placements Clermont ltée ( Les).2480 Rohr Textile Waste Inc.2481 Slax Inc.2482 Auberge du Portage inc.2472 Bettv Speirs-Peter Miller Dance Studios Ltd.(The).2472 Cedar Corporation.2472 Dyno Corporation (The).2472 Entreprises Robert inc.(I-cs).2472 Florès inc.2472 Lutfy Realties Ltd.2473 M.& S.Publications liée.2473 Mackle Commercial Centre Inc.2473 Pinnacle Investment Corp.2473 Servitor Inc.2473 Transit Drv Kiln Lumber Company Limited (The).2473 Divers Miscellaneous Amerlux Steel Products Corporation (Agent).2483- Asicor inc.(Nom-Name ch.).2484 Bertrand Lumber Inc.(Dir.).2484 CIP Homes Limited (Dir.).2482 Candiac Equipment Company Limited (Dir.).y.- 2482 Centre d'accueil de Wickham inc.(Rcg- Bij-lairs).2483 Eastern Electric Co.Ltd.(Dir.).2484 Fabro Investments Ltd.(Dir.).2483 Fleur de Lys Motel Inc.(Dir.).2485 Giroux -Louis & Associates Inc.(Name eh.).2484 Giroux (Louis) & Associés inc.(Norn ch.).2484 Habitations CIP limitée (Les) (Dir.).2482 Holt Rcmlrew & cie, limitée (Dir.).2483 Holt Renfrew & Co., Limited (Dir.).2483 2532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 ami 1970, 102' année, n° 17 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Hôpital d\" Haut-Richelieu (Rigl.-By- laws).2485 McGill Auto Park Inc.(Dir.).2483 Olram Enterprises Inc.(Xoin-Xamc ch.).2484 Orion inc.(Dir.).2483 Service des loisirs Stc-Madeleine-Sophie- Barat (Règl.-By-latos).24S4 Société française de cosmétologie ltée (Dir.).2485 Lettres patentes letters Patent Administrateurs rue Sherbrooke ouest inc.2402 Agence dc collection interprovincialc inc.v.2402 Agence Karewells inc.(Les).2403 Agents de Réclamations W.Y.O'Brehaminc.2449 Aget Finance Corporation.2403 Alouette Investments Inc.2455 Arkclinc.2403 Arnel Commercial Enterprises Ltd.2404 Artemis Sportswear Ltd.- 2404 Association des Anciens et des Amis dc la paroisse Notre-Dame-de-la-Défense 2405 Association des Résidents du l.ac Blanc, inc.2405 Association féminine de Hockey sur gazon dc la province de Québec inc.2458 Association récréative et culturelle de Cléricy (L'Arc de Cléricy) (L').2400 Assurances P.-l.ouis Lepage ltée.2406 Ateliers audio-visuels du Québec (Les).2400 Avimat inc.2407 B.D.& E.Marketing Agency Inc.2407 Barrette (Jacques) inc.2407 Bas Vuléric inc.240S Bédard (L') & Associates Limited.240S Bédard (I/) & associés limitée.2408 Bédard, Lavoie & Lessard inc.2408 Bélanger Autorama ltée.2409 Bélanger & Blanchettc ltée.2409 Bclladona Institute Inc.2438 Bonaventure 2102 Ltd.2409 Bonncau Teasdatc Enterprises Ltd.2426 Boutique dc créations pour enfants Rachel inc.2410 Brasserie La Chaudière inc.2410 Breuvex inc.2410 Brigitte Hnutc Coitfure inc.2411 CJMD inc.2411 C.L.électrique inc.2411 CRM Capital Limited.2412 Calais Auto Parts Inc.2454 Camp-École Chicobi Inc.2412 Candy Sportswear Ltd.2412 Capitol Automobile Inc.2413 Carib-Canada Corp.2413 Centre dc Mécanique Industrielle Marquis & Faucher inc.2413 Centre de Radio de Magog inc.2414 Centre dc Vinyl Métropolitain ltée .2414 Centre récréatif dc Blainville inc 2415 Centre Récréatif de Coteau Station.2415 Chalac inc.2415 Chaton Bleu inc.2416 Champion Leasing Inc.2442 Christine Pizza Inc.2416 Ciné-parc route 9 inc.2416 Claubert inc.2417 Cie Elum River Mickel Ltd.2417 Clinique Médicale dc Rimouski inc .2417 Club Acadien Sept-Iles.2418 ('lub Auto-Neige Lac Bouchette inc.24IX Club Auto-Neige St-Basile inc.2418 Club dc hockey Chicoutimi inc.2419 Club dc (iolf dc Plessisville ltée.2419 Club dc tir de Saint-Tite inc.v .- 2419 Club Kiwanis de Drummondville inc.2420 Club moto-ncige Neuville inc.2420 Club sportif universel inc.2421 ( 'om|>clcc inc.2421 Comptoir familial île la région dc l'Amiante inc.2421 Concord Sportswear Ltd.2422 Conseillers en sports Pro-Am ltée.2457 ( 'onstmetion Sotcr incorporée.2422 ( 'onsultants FM B inc.(Les).2422 Cornet Blanc (Miron) incorporée (Lc) 2423 Cyr (Renald) inc.2423 Dafomax inc.2423 Diversified Communications Limited.2424 Dix associés inc.(Les).2424 Dubord composition inc.2424 Duclos assurances inc.2425 Duclos Insurance Inc.2425 Duo construction inc.2425 Eastern Mechanical Service Ltd.2425 Écoles Chateau Picrrefonds inc.2420 Elite.Patterns Works Inc.2420 Entreprises Bonncau Teasdale ltée (Les) 2420 Entreprises La Ronde inc.2427 Entreprises Les Signes du Zodiaque inc.2427 Entreprises Mcico inc.2427 Epcoli Inc.2428 Exccllo Imports Co.Ltd.242s Everest Construction Inc.242S F.L.Sales Inc.2429 FMB Consultants lue.2422 Fashion First Manufacturing (1909) Ltd.2429 Fédération Québécoise des Sociétés d'Aviron inc.2430 First Édition Fashions Ltd.2430 Fondationdc l'hôpital «lu Sucré-Coeur dc Montréal.2430 Fondution Gertrude Boyer.2431 Fondeco inc.2431 Fovcr Dorval.2431 Foyer dc Sutton inc.(Le).2407 Frcsal Holding Inc.2432 G.L.R.Inc.2432 Galerie d'art Langelier inc.2432 Gatineau oxygène inc.2433 Gestion Gaétan Laurence ltée.2433 Gestion Réal Laurence ltée.2433 Gestion René Laurence ltée.2434 Global Importers Ltd.2434 Granby Bar inc.2434 Griffe de Paris inc.2435 Guertin (Michel) inc.2435 Guild'or Inc.2435 Happy Life Distributors Ltd.2430 Hcmmingford Orchards Inc.2436 Heppell & Bouchard inc.2436 Hôpital Quinn inc.2437 Icarus Food Importers Co.Ltd.2437 Immeubles: Roland Hébert ltée (Les) .2437 Imprimerie Mikado inc.2438 Industries Wickham inc.(Les).2471 Institut Belladone inc.2438 Interprovincial Collection Agency Inc.2402 Investissements F é I i c y n o p h y 1 i q u e s (F.C.) inc(Lcs).2438 Investissements M.L.T.C.inc.2439 Karewells Agencies Inc.2403 King (M.E.) Claims Adjusters Inc.2439 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2533 Lettres patentes Letters Patent (mite) (continued) Kiwanis Club of Drummondville Inc.2420 Laboratoires Bio cliniques inc.2440 Laiterie Bélanger & fils ltée.2440 Lara Shops Inc.2440 Lauzon (Yves) & fils inc.2440 Lave-auto Shawinigan inc.2441 ljcfebvrc (Roger) automobile inc.2441 Lemieux (Raymond) inc.2442 Librairies du nord inc.(I-es).2442 Location Champion inc.2442 Lorilou Stables Inc.2443 Macdonald College Faculty Glûb (The), 2443 Maison Joseph Battat ltée.2443 Maisons Mobiles Riviéra ltée.2444 Malenfant (Guy) sports inc.2444 Manie Electric Ltd.2444 Manoir Mont-St-Hilairc Inc.2445 Marshall (G.) Siew Inc.2445 Martel Detroit Diesel Limited.2445 Martel (Frank) Moving & Storage Ltd.2440 Maxwell (J.H.) Mfg.Inc.2440 McCoy Lake Mines Limited.2446 Metropolitan Vinyl (\"enter Ltd.2414 Mibar (Québec) Inc.2447 Midtown Auto Park Inc.2447 Mines du Lac McCoy limitée (Les).2440 Montcalm Mobile Homes Ltd.2463 Montréal Est sport limitée.2447 Morin construction inc.244S Motels Forillon dc Rivicrc-au-Rcnard inc.(Les).244S Motorized Industrial Products Ltd.2457 N.D.G.Health Spa Inc.2448 Nello Pizzeria Inc.2449 New Ornamental Metal Works Inc.2449 O-RA-L-0 inc.2450 O.T.J.Ste-Marthe inc.2451 O'Breham (W.Y.) Claims Adjusters Inc.2449 Olna Investments Ltd.2450 P.G.auto location ltée.2451 P.R.Finance inc.2451 P.V.C.Isolation inc.2452 Pagode Tours Inc.2452 Pamikc Mines Limited.2452 Park'n Fly of Montreal, Ltd.2453 Pclavo inc.2453 Perrault (Paul) construction liée.2453 Petite Riviere Navigation inc.2454 Pieces d'uuto Calais inc.2454 Place Du nan I Inc.2454 Placements Alouette inc.2455 Placements diversifiés du Québec ltée (Les).2459 PlacementsGestal inc.(Les).2455 Placements Gomar inc.2455 Placements J.F.R.M.ltée (Les).2450 Placements Le Duc inc.( Les).2456 Plomberie Benoit inc.2450 Pro-Am Sports Consultants Ltd.2457 Productions S.M.C.L.inc.(Les).2457 Produits Industriels motorisés liée (Les) 2457 Progesco inc.2458 Province of Québec Women's Field Hockey Association Inc.2458 Prud'homme (.I.C) inc.2459 Québec Diversified Investments Ltd.2459 Québec Federation of Rowing Societies Inc.2430 Québec Wood Shavings Incorporated.2459 Rachel Children's Creations Houliquc Inc.2410 Racz Taxi Center Ltd.2460 Ranville Construction Inc.2460 Reno-Con ltée.2460 Restaurant à la Barrique inc.2461 Restaurant de l'auditorium de Verdun inc.2461 Restaurant Lc Buffet inc.2461 Restaurant Le Sabayon inc.2462 Restaurant L'Étape de Magog inc.2462 Rexley's (1970) Inc.2462 Riviéra Mobile Homes Ltd.2444 Roulottes Montcalm ltée.2463 Roy, Bélanger & associés ltée.2463 Ste-Martine Automobile inc.2463 S.M.C.L.Productions Inc.2457 Scgumo inc.2464 Service mécanique de l'Est liée.2425 Service dc soins coordonnés à domicile du Montréal métropolitain.2464 Shawinigan Car Wash Inc.2441 Sherbrooke Street West Administrators Inc.2402 Sinar Inc.2464 Snowmobile Service Ltd.2465 Société d'Administration des plans dc Bien-Être.2465 Société d'Investissement de Maria inc.2466 Société dc gestion Immobec inc.2466 Spingola (Frank) & Sons Ltd.2460 Spingola (Frank) cl fils ltée.2466 Sutton Home Inc.(The).2467 Sydmais Ltd.2467 T.S.D.construction ltée.2467 Tabagie Horizon inc.2468 Tabah Import Inc.2468 Telindex inc.2468 Thermatrol of Canada Ltd.2469 Tourbec inc.,.2469 Tractions-mobiles Lévesquc inc.2469 Transilvania Credit House Inc.2470 T-Vcno inc.2470 Universal Sporting Club Inc.2421 Valeric Hosiery Ine.2408 Variétés R.Labrosse inc.2470 Venture Capital Corporation.2471 Verdun Auditorium Restaurant Inc.2461 Vergers d'Hcmmingford inc.2436 Vogue Knitting Mills Ltd.2471 Vêtements sports Concorde ltée ( Les).2422 Wickham Industries Inc.2471 Welfare Plan Administration Board.2465 Sièges sociaux Head Offices B.C.T.Enterprises Ltd.2479 Centre de diagnostic & dc service ville inc.2478 Centre Furniture Co.Ltd.2480 Confédération des harmonies-fanfares du Québec (La).247S Conseil dc développement «le la c«Hc du Sud.2477 Côté (Ernest) ltée.2477 Décor Fleury limitée.2478 Design Management Inc.2477 Entreprises B.C.T.liée (Les).2479 Morin Coderre and Associates Inc.2478 Morin Coderre et associés inc.2478 Pcllerin Spectacle inc.2479 Salle à manger la ( iaspésienne inc.2479 Salon Commodore (Charlesbourg) inc.2479 Sinar inc.2479 Town Diagnostic & Service ( 'entre Inc.247S Universal Hobby Supplies Ltd.2477 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 avril 1970, 102' année, n\" 17 DEMANDES APPLICATIONS à la Legislature to Legislature Administration Trust Compagny.2476 Association des comptables généraux licenciés de la province dc Québec (L') 2476 Black, Henderson.2477 Certified General Accountants' Association of the Province of Québec (The) 2476 General Trust of Canada.2476 Malik, Mme Mireille.2477 Séminaire St-Germain de Rimouski.2476 Seminary of St-Gcrmain de Rimouski 2476 Société d'administration et dc fiducie.2476 Trust Général du Canada.2476 LIQUIDATION WINDING avis de un Notices Cie dc sable & dc gravier Montmorency ltée (La).2488 .MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires iiiiinicipulcs Municipal Aairs St-.Ican, ville (Fusion volontaire).2523 St.John's, city (Voluntary Amalgamation).2523 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipulity of: Lc Rover, c.s.r.-r.s.b.2500 Sherbrooke (Dcm .-A ppl.).2500 Instilii lions Financial financières.Institutions.compagnies Companies et coopératives und Cooperatives Assurance: Insurance: Citadel Insurance Company of Canada Limited (The) (Annul.).2497 Indus-trie Industry cl commerce und Commerce Avis de pêche aux coquillages.2500 Shell fishing notice.2500 Terres et Forêts Lands und Forests Cadastre: Cadastre: Bpurlamaque, canton-townsliip.2501 Bouthillicr, canton-townsliip.2501 Charlesbourg, par.2474 Halifax, canton-townsliip (l'art.Rce.).2502 Joly, canton-townsliip.2474 Louvicourt, canton-townsliip.2501 Lussier, canton-townsliip.2502 Montréal, cité city (Quartier Ste-Aniu Ward).2474 Notre-Dame de la Victoire, par.2474 Provost, canton-townsliip.2502 Rawdon, canlon-towiiship.2474 St-Ambroise dc la Jeune Lorette, par.(Part.Rev.).2502 Ste-Anne de Chicoutimi, village.2502 St-Antoinc de Longueuil, par.2474 St-Colomb dc Sillery par.2502 Ste-Cécile, par.2475 Ste-Foye, pur.2475 St-Laurcnt, pur.2503 NOMINATIONS APPOINTMENTS Agents officiels.2496 Allurd, Jules (coroner suppléant-actiilg coroner).2495 Arsenault, Jean-Marc (coroner).- 2495 Bernard, Fernand (coroner supplcant- ncting coroner).2495 La Haycr, Gilles (juge des Sessions-Judge of the Sessions).2490 Officials Agents.2490 Séguin, Bernard (coroner).2495 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Coming into force of a part of the official cadastre of the township of Boisseau, situated in the registration division of Abitibi.2492 ( 'uining into force of the revised cadastre of u part of the parish of St-Frunçois, situated in the registration division of Bcaucc.2490 Convocation de la Législature.2493 Convocotion of the Legislature.2493 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville dc Beauport au village dc St-Jcan-de-Boischntcl, comté de Montmorency No 1.2491 Extcnsioii of the jurisdiction of the Municipal Court of the township of Beauport to the village of St-.lcnn-dc-Boischatel, county of Montmorency No.1.2491 Mise en vigueur du icadastrc officiel d'une parue du canton dc Boisseau, située dans lu division d'enregistrement de l'Abitibi.2492 Mise en vigueur du cadastre revisé d'une partie de lu paroisse dc St-François, située dans la division d'enregistrement dc Bcaucc.2490 RÉGIE QUÉBEC des marchés agricoles Agricultural du Québec Marketing Board Eggs for consumption producers, Québec (Joint Plan).2527 Eggs for consumption producers, Québec (Quotas).2528 Milk producers of Quebec South (Joint Plan).2526 Producteurs d'oeufs de consommation, Québec (Plan conjoint).2527 Producteurs d'oeufs dc consommation, Québec (Quotas).2528 Producteurs dc lait dc Québec-Sud (Plan conjoint).2526 Producteurs de lait nature de In région du nord-ouest Québécois (Plan conjoint) .2528 Raw Milk Producers of North-Western Québec (Joint I'lan).2528 SOUMISSIONS TENDERS Grand-Calumet, canton-township.2503 Longueuil, ville-city.2512 Montcalm, c.s.-s.c.2505 Princeville, villc-town.2506 St-Antoine, villc-town.2508 St-Césaire, villc-town.2511 St-Pascal, villc-town.2514 St-Pierre-dc-ln-Rivière-du-Sud, par.2509 Touraine, mimic.2516 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 25, 1970, Vol.102, No.17 2535 SYNDICATS PROFESSIONAL professionnels Syndicales Association des fonctionnaires municipaux dc Dorval (C.S.N.) (Nom-Namc ch.).2494 Association des professeurs de l'école polytechnique de Montréal (Const.-Inc.).:.2494 Association professionnelle du personnel dc direction et de gestion de lu fonction publique (Const.-Inc.).2495 Association Québécoise des pharmaciens propriétaires (I/) (Const.-Inc.).2494 Fédération des cadres scolaires (Const.- Inc.).2494 Fraternité des policiers de Longueuil (La) (Nom-Numc ch.).2495 VENTES SALES SHÉRIFS SHERIFFS Gaspé Gaspé Division Iles Division of the de la Madeleine M agdalen Islands Ideal Stainless Steel Inc.es Longuépée.2530 Montréal Montréal General Trust of Canuda es Labrosse (Erratum)._.2530 Prudential Insurance Company of America (The) vs Coatcs (Erratum).2530 Pnidcntielle d'Amérique compagnie d'assurances (La) vs Contes (Erratum).2530 Trust Général du Canada es Labrosse (Erratum).2530 Taxes Taxes Matanc, ville-town.2523 Richmond, ville-town.2521 Sherbrooke, comté-eounty.2518 Shawinigan, cité-city.2522 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.