Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 19 septembre 1970, samedi 19 (no 38)
[" 102' ANNEE ,oi.102 I 2UEBEC N» 38 5251 \"3uéqec kiette officielle à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 19 septembre 1970 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée eu plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur ongueur ou pour des raisons d'ordre administratif.i\" Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans \u2022me première insertion, les intéressés sont priés den aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et a autre des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, September 19,1970 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazelle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Officiai Publiiher 5252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102e aimée, n° SS Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocn Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 33015 \u2014 1-52 Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 35 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents per agate line for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, S20; April 1st to December 3ht S15 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number ol insertions.The letter \"o\" indicates that the test was not composed or translated by The Quebec Official Publisher personnel.Notices published only once arc followed by our invoice number.Rocii Lefebvre, Quebec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 19G9 3:i(ll5 -1-52 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-casli \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes Agence Ilaudmcl inc.Ilntidiiu'I Agency Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de juin 1970, constituant en corporation: .Maurice Duhamel, enquêteur, 7265, Malo, Brassard, Robert Duhamel, publicistc, 412, des Pins, Saint-Bruno-dc-Montarvillc, et Paul Duhamel, comptable agréé, S493, Georges, LaSalle, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits, articles et marchandises de tontes sortes, sous le nom de « Agence Ilaudmcl inc.\u2014 Haudmel Agency Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominnlc de SI chacune et en 390 nctions privilégiées d'une valeur nominale de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 43, Esterai, (Étage E), Place Bonavcntùre, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Pniui'Pi: Bouchard.36234-0 2754-1970 Agences distribution C.R.R.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de juillet 1970, constituant en corporation : Roger Rioux, gérant, Claire Lanteigne, ménagère, épouse dudit Roger Rioux, et Miehel-L.Rioux, Letters Patent Agence Ilutidmel inc.Ilaitilmrl Agency Inc.Notice is given that under Pari I of llie Companies Act, letters patent, bearing date II* 17th day of June, 1970, have been issued by llie Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice Duhamel, investigator, 7265 Malo, Brossard.Robert Duhamel, publicist, 412 Des Pins, Sainl-Hriinc-dc-Monlarville, and Paul Duhamel, chartered accountant, 8493 Georges, LaSallè, for the following purposes: To deal in products, articles and g.Is of all kinds, under the name of \"Agence Ilaudmcl inc.\u2014 Haudmel Agency Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1.000 common shares of a nominal value of *1 each and 390 preferred shares of a nominal value ol SlOOcach.The head office of the company i> at *> Estcrel, (E Floor), Place Bonavcnturo, Montreal judicial district of Montreal.Ls-PlllLlPPE BoUClIAHD.Dcqnity Minister of Financial Institution*, Companies and Cooperatins.36234 275-1-1W Agences distribution C.R.R.ii\"'.Notice is given that under Part I of Uj Companies Act, letters patent, bearint; date W 7th day of July, 1970, have been issued by t.« Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Ijious.manager, Claire Lanteignc, housewife wife »' the said Roger Rioux, and Miehel-I.Rworating: Maurice Ber-nicr, industrialist, 2660 Hamury, Laval, Martial Morin, professor, Mont-Laurier, and Astrid Morin, secretary, spinster of the full age of majority, 5960 Pie IX, Montreal, for the following purposes: To manufacture anil deal generally in all articles used for hospital furnishings and utilities, under the name of \"Bcrtec inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is at 2635 Charlemagne Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inst il niions, Companies and Cooperatives.36234 2771-1970 Best Theatre Supply Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Armand Bessc, trader, 9370 Saint-Hubert, Montreal, Richard Barbeau, 275 Amédée-Mcunier Avenue, Rcpcntigny, and Jean Gcoffrion, 1120 Bernard Avenue West, Apt.34, Outrcmont, the latter two advocates, for the following purposes: To operate a theatre agency, under the name of \"Best Theatre Supply Inc.\", with a total capital stock of 845,000 divided into 500 common shares of 810 each and 4,000 prcferretl shares of 810 each.The head office of the company is at 4810 St-Denis Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2581-1970 G.Ili nul k.i u Accident Assurance Inc.Assurance accident G.Boudrcaii inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of August, 1970, have been issued by the 5256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, JO .septembre 1070, 102' année, n° 38 il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'août 1970, constituant en corporation: Géraldine Knright, secrétaire, épouse de Guy Boudreau, 78, Jacques-Cartier, Alain Boudrcau, administrateur, 325, avenue des Éiables, tous deux dc Granby, et Robert Brasseur, agent d'assurance, Valcourt, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom dc « G.Boudreau Accident Assurance Inc.\u2014 Assurance accident G.Boudreau inc.», avec un capital total dc 810,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 90 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-mini.strc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Fiui.iiM'k BorriiAHi).36234-0 3363-1970 Boutique Au Vieux Grenier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour d'août 1970, constituant en corporation: Monique Durand, secrétaire, Francine Morricr, hôtesse, toutes deux filles majeures, de 10360, Place Taché, André Lavoic, commerçant, 10860, Esplanade, tous trois de Montréal, et André-Pépin, superviseur, 155, Bclislc, Saint-Eustache, pour les objets suivants: Exploiter des magasins de bonneterie, rol)cs, vêtements et articles accessoires, sous le nom de «Boutique Au Vieux Grenier inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc 81 chacune et en 3,900 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Pmlippe BorciiAiu).36234-0 3390-1970 W.Brindainour inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne nvis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc juin 1970, constituant en corporation: William Brindamour, homme d'affaires, 38, Desjardins, James McDonald fils, 40, Desjardins, tous deux de Saint-Félix-du-Cap-Rouge, Lorenzo Fournier, tous deux techniciens, et Claude Fournicr, commis, ces deux derniers de 417, lrc rue, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs en réfrigération, plomberie et chauffage et faire le commerce dc toutes sortes d'appareils ou systèmes de réfrigération, ventilation, climatisation dc l'air, plomberie, chauffage et électricité, sous le nom de « W.Brindamour inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-viinistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIlI.lI'l'k Bouciiahu.36234-0 2815-1970 Buckland Mctal Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu Minister of Financial Institutions.Comptait] and Cooperatives, incorporating: Géraldine Knright, secretary, wife of Guy Boudronu, 7S Jac-qucs-Carlicr, Alain Boudreau, administrator 325 Maple Avenue, both of'Granby, and Robert Brasseur, insurance agent, Valcourt, for \\\\t following purposes: To carry on business as insurance brokenaa| agents, under the name of \"G.Boudreau Acddtal Assurance Inc.\u2014 Assurance accident (!.drcau inc.\", with a total capital stock of S10,01».divided into 1,000 common shares of §| Paco and 90 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is al Granit judicial district of Bedford.Ls-Piiii.iite BouciiAitn, Deputy Minister of Financial Instil niions, Companies and Cooperatirts, 36234 :!:iii:|.|9;o Boutique Au Vieux Grenier inc.Notice is given that under Pari I of ||» Companies Act, letters patent, bearing dale flu 5th day of August, 1970, have been issued lit the Minister of Financial Institutions.Compos and Coo])crativcs, incorporating: Monique Do-rand, secretary, Frnncinc Morricr, hostess, loti spinsters of the full age of majority, of ' Place Taché, André Lavqic, merchant, lOSD) Esplanade, all three of Montreal, ami Awlri Pépin, supervisor, 155 Bclislc, St.Kustnche, l« the following purposes: To run hosiery, dress, clothing and accrs-orj shops, under the name of \"Boutique An Vim (irenier inc.\", with n total capital slock of S-IO.OM divided into 1,000 common shares of s I each an! 3,900 preferred shares of 810 each.The head office of the company is al Montrai judicial district of Montreal.Ls-Pnii.ii'pk Boi iu.miii.Deputy Minister of Financial Inslilul'mm.Companies and Coopenlim.36234 330W» \\V.Brindumour inc.Notice is given that under Pail I ol Ik Companies Act, letters patent, hearing dill the 29th day of June, 1970, have been issufJ by the Minister of Financial Institutions, Cot panics and Cooperatives, incorporating: Wiuas Brindamour, businessman, 38 Dcsjanlins, Job McDonald, jr, 40 Dcsjanlins, both of Saint-Fa* du-Cap-Rouge, Lorenzo Fournier.both let** clans, and Claude Fournier, clerk, llie latter I\" of 417, 1st Street, Québec, for the follôn) purposes: To carry on business as contractors in refn-gcration, plumbing and heating and Io deals all kinds of refrigeration, ventilation, air-coo* tioning, plumbing, heating and electrical W terns, under the name of \"W.Brindamour inc.with a total capital stock of $40,000.divuW into 4,000 common shares of a nominal val* of 810 each.The head office of the company i- nl Qww judicial district of Quebec.Ls-Piiii.ipi'K Bon » viiii.Deputy Minister of Financial iwliMuiK Companies ami Cotipcrdu*, 36234 2815-1*1 Buckland Mctal Inc.Notice is given that under Pail j ' * Companies Act, letters patent, hearing ¦ QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, September JO, 7.970, Vol.102, No.38 ,1c In première partie de la Loi des compagnies, j| :, ;\u201e.dé des lettres patentes, en date du 7c jinir d'août 1070, constituant en corporation: Hdlicillî.I.afrenièrc, (ial)riel Loubicr et Jean Morin.tous trois avocats, dc 580, Grande-Allée ist, Qtiél>cc, pour les objets suivants: Fabriquer cl faire le commerce de marchandises r) articles fabriques totalement ou en partie dc métaux, bois ou plastique, sous le nom dc « Buck-land Metal Inc.\", avec un capital total dc 8125,000, divisé en G00 actions ordinaires de $100 chacune cl en 050 actions privilégiées de 8100 chacune., l.e siège social de la compagnie est.à Nolre-|)aiiic-Aiixilialricc-do-Buekland, district judiciaire de Montmngny.U tous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopérai ires, Ls-Pllli.tri'u BoucifARO.36231-0 3438-1070 Biismac Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé îles lettres patentes, en dnlc du 12c jour de juin 1970, constituant en corporation: IRaymond l.ccompte, 741, Laurier, Gilles Bus-Isièris, tous deux électriciens, et Edith Urecn, I ménagère, é]>ousc dudit Gilles Bussièrcs, ces I lieux derniers de 900, Harricana, tous trois dc I Malartic, pour les objets suivants: Faire affaires comme foreurs et chercheurs dc Imines, sous le nom dc « Busmnc Inc.», avec un I capital total de 840,000, divisé en 200 actions Iordinaires de S100 chacune et en 200 actions I privilégiées dc 8100 chacune.l.e siège social de la compagnie est à .Malartic, Iilislrii-l judiciaire d'Abitibi.IUsous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Phii.ippi: Bouchard.|302:i4-o 2590-1970 Les Cafétérias Itotavc liée I Le ministre des institutions financières, com-Ipagnics et coopératives donne avis, qu'en vertu l|le la première partie dc la Loi des compagnies, IH a accordé des lettres patentes, en date du 4e Ijour d'août 1970, constituant en corporation: ¦Gustave Fautcux, représentant, 181, Crémazic louest, Louise Bigras, sociologue, fille majeure, 3, ISt-Staiii>las, tous deux de Québec, et Jcanninc ILarochclIc.traiteur, épouse dc Roger Shields, 11-12, des Cyprès, Orsainville, pour les objets Buvants: I Exploiter des salles à manger, casse-croûte, \u2022cafétérias, cabarets, bars-salons, hôtels, motels fc! ni!|'S(>ns de pension, sous le nom dc « Les lyifetérias Rotavc liée», avec un capital total Ile $40,000, divisé en 200 actions ordinaires d'une P*\"f .ninate de 8100 chacune et en 200 \u2022étions privilégiées d'une valeur nominale de ¦100 chacune.I Le siège social de la compagnie est 2140, rue P Assise, Québec, district judiciaire de Québec.W**ou*-miuistredcs institutions financières, compagnies et coopératives, l.Ls-Philippe Bouchard.p»-\" 3287-1970 Canapoma Ltd.I be ministre des institutions financières, com-jwgnies et coopératives donne avis, qu'en vertu the 7th day of August, 1070, have been issued by the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roborl-B.Lafrcnièrc, Gabriel Loubicr, and Jean .Morin, all three advocates, of 5S0 (irandc-Allée East, Québec, for the following purposes: To manufacture ami deal in merchandise anil articles made in whole or in part of metal, wood or plastic, under the naine of \"Buckland Metal Inc.\", with a total capital slock of 8125,000, divided into 000 common shares of 8100 each and G50 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Notrc-Damc-Auxiliatricc-dc-Buckland, judicial district of Montmngny.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.3(1234 3438-1970 Biisiiiuc Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of June, 1970, have been issued by the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Le-compte, 741 Laurier, (idles Bussièrcs, both electricians, and Edith Brcen, housewife, wife of said Gilles Bussièrcs, the lutter two of 9G0 Harricana, all three of Malartic, for the following purposes: To carry on business as mine drillers and seekers, under the name of \"Busmuc Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Malartic, judicial district of Abitibi.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.30234 2590-1970 l.cs Cafeterias Rolave liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4 lb day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gustave Fau-teux, representative, 181 Créma/.ie West, Louise Bigras, sociologist, spinster of the full age of majority, 3 St-Stanislas, both of Québec, and Jeanninc Larochclle, caterer, wife of Roger Shields, 4212 des Cyprès, Orsainville, for the following purposes: To operate dining-rooms, snack bars, cafeterias, cabarets, bar salons, hotels, motels and boarding-houses, under the name of \"Les Cafétérias Rotavc liée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 200 common shares of a nominal value of S100 each and into 200 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at 2MO d'Assise Street, Québec, judicial district of Québec.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3Q234 3287-1970 Canapoma Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 88 dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour dc juillet 1970, constituant en corporation: John M.McDougall, Peter E.Graham et Robert James Stocks, tous trois avocats, du 000 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de monte-pentes, télésièges et, en général, dc tout equipment ou mécanismes utilisés pour le ski, sous le nom dc « Canapoma LUI.», avec un capital divisé en 100,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Blainvillc, district judiciaire dc Terrebonne.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies cl coopérai ires, Ls-Pi huppe Bouchard.36234 3049-1970 Jean-Paul Carrier inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour dc juillet 1970.constituant en corporation: Jean-Paul Carrier, entrepreneur, Noëlla Carrier, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Carrier, tous deux de 76, de Salalnrry, Saint-Jean, et Henri (îirard, électricien, 354, St-Joseph.Saint-Grégoirc-Ie-Grnnd, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens, fabriquer et faire le commerce de toutes sortes d'appareils et accessoires électriques, sous le nom dc « Jean-Paul Carrier inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 76, rue dc Salaberry, Saint-Jean, district judiciaire d'Ibcr-villc.7,e sons-ministre des institutions financières, compagnies et rpératires, Ls-Philippe Bouchard.36234-o 2861-1970 Centre de molo-neigc Stc-Martbc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de juillet 1970, constituant en corporation: Guy Bélisle, 124, Grande-Côte, Gaston Binette, 102, De Bellefeuillc, tous deux notaires, et Françoise Théorêt, secrétaire, épouse dc (Juy Jérôme, 91, De Bcllefcuille, tous trois de Saint-Eustachc, pour les objets suivants: Exploiter une ou plusieurs pistes dc karts, motos-neige et autres places d'amusement, sous le nom dc « Centre dc moto-neige Ste-Marthc inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainle-Marthc-sur-lc-Lac, district judiciaire dc Terre-bonne.1* sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.30234-o 3141-1970 Centre du pneu Asbestos inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, 14th day of July, 1970, have been issued by tin-Minister of Financial Institutions, Compuuej and Coo|)crativcs, incorporating: John M.\\|f.Dougall, Peter E.Graham and Robed .lnm,.s Slocks, all three advocates, of 600 Dorclieslei Boulevard West, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ski lift, cliair-lift and generally all such devices and equipment for the sport of skiing, under the name of \"Cnnj.puma Ltd.\", with a capital stock divided into 100,000 common shares without par value.The head office of the company is at ItuinriBr judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Boucha tin, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-0 3040-1978 Jean-Puiil Carrier inc.Notice is given that under Part I of i|;r Companies Act, letters patent, bearing date ||* 9th day of July, 1970.have been issued by Ik Minister of Financial Institutions, ( 'omponin and Cooperatives, incorporating: Jean-Paul Car-rier, contractor, N'oella Carrier, housewife, wile of said Jean-Paul Carrier, both of 7l> de Salaberry, St.John's, and Henri Girard, electrician.354 St-Joseph, Snint-Grégoire-lc-Grnnd, for Iht following purposes: To carry on business an electricians, to manufacture and deal in all kinds of electric appliance and accessories, under the name of \"Jean-Pad Carrier inc.\", with a total capital -lock of $40,000, divided into 1,000 common shares ol S10 each and 300 preferred shares of $100 eaeh.The head office of the company i- at Tli ile Salaberry Street, St.John's, judicial district ol Iberville.Ls-Piiilippe BorniAiin.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperalires.36234 286I-1KI Centre de moto-ncig-.- Stc-Martlie inc.Notice is given that under Pari I of the Companies Act.letters patent, bearing dale the 14th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: GtJ Bélisle.124 Grande-Côte, Gaston Binette, KB Dc Bcllefcuille, both notaries, and Kraacail Théorêt, secretary, wife of Guy Jérôme, !M De Bcllefcuille, all three of Saint-F.ustuchc.lor ll« following purposes: To operate one or several karl tracks.snot-mobile centres and other amusemcnl places under the name of \"Centre dc moto-neige Ste-Marthe inc.\", with a total capital stock ¦ $40,000.divided into 2,000 common .-hares of » nominal value of $10 each and into 2,000 P\"-ferred shares of a nominal value of $10 earli.The head office of the company is al Same Marthc-sur-le-Luc, judicial district of ten* bonne.Ls-Piulippe BouciiAito, Deputy Minister of Financial /»*///»'»\"\"¦ Companies and Cooprralint.36234 3141-lïi» Centre du pneu Asbestos inc.Notice is given that under Pari I of* Companies Act, letters patent, bearing, '»» the 24th day of July, 1970, have bec» Wfl J QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September J!), 1070, Vol.102, No.38 5259 il n accordé (les lettres patentes, en date du 24c jour de juillet 1970, constituant en cor|k>ration: Marc Itivard, étudiant, 770, Buck, Rosario Grenier, comptable, 580, Pelletier, et Jacques O'Hready, avocat, 581, Bouchctte, tous trois dc Sherbrooke, jKiur les objets suivants: l'aire le commerce dc pneus de toutes sortes, sous le nom de « Centre du pneu Asbestos inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 action- ordinaires d'une valeur nominale dc 810 chacune et en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale de 8100 chacune.I.c siège social dc la compagnie est à Asbestos, district judiciaire de Saint-François.U ¦'¦iins-iii in istre des inst il ut ions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchau».36234-0 2813-1970 Gilles Chalifour limitée Cilles Chalifour Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de juin 1970, constituant en corporation: Gilbert Nadeau, représentant, Aline Hurtubisc, ménagère, épouse dudit Gilbert Nadeau, tous deux dc 6461, Chouinard, et Maryan Nadeau, ménagère, éixmsc dc Gilles Chalifour, 6260, 27e avenue, tous trois dc Montréal, pour Ici objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc machines à coudre, moteurs, outils, instruments et quincaillerie île toutes sortes, sous le nom dc « Gilles Chalifour limitée \u2014 Gilles Chalifour Limited », avec un capital total dc 840.000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Piiiuppe Bouchard.36234-0 2777-1970 Chamhly Mould & Die Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour d'août 1970, constituant en corporation: Gabriel ('harland, 211, des Érables, Carignan, Clément Lussier, tous deux outillcurs, et Lise Bessette, ménagère, épouse dudit Clément Lussier.ces deux derniers dc 1103, Gludu, Muricvillo, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de métaux de toutes sortes, leurs produits et sous-produits, sous le nom de « Chamhly Mould & Die Inc.», avec un capital divisé en 5,000 actions ordinaires sans videur nominale et en 200 actions privilégiées de 81(10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Chamhly, district judiciaire de Montréal.Usinis.iniiii.ilre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.362*|-o 3384-1970 La Clinique de Médecine familiale d'Alma inc.Le ministre des institutions financières, compagnies coopératives donne avis, qu'en vertu « la première partie de la Ia>\\ des compagnies, by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marc Rivard, student, 770 Buck, Rosario Grenier, accountant, 580 Pelletier, and Jacques O'Bready, advocate, 581 Bouchettc, all three of Sherbrooke, for the following purposes: To dcnl in tires of all kinds, under llie name of \"('entre du pneu Asbestos inc.\", with a total capital slock of 840,000 divided into 2,000 common shares of a nominal value of 810 each and 200 preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at Asbestos, judicial district of Saint-François.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2813-1970 Gilles Chalifour limitée Gilles Chalifour Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilbert Nadeau, representative, Aline Hurtubisc, housewife, wife of said Gilbert Nadeau, both of 6401 Chouinard, and Maryan Nadeau, housewife, wife of Gilles Chalifour.6260, 27th Avenue, all three of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in sewing machines, motors, tools, instruments and hardware of all kinds, under the name of \"Gilles Chalifour limitée \u2014 Gilles Chalifour Limited\", with a total capital slock of S40.000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234 2777-1970 < 'li.mibl> Mould & Die Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gabriel Char-land, 211 Des Érables, Carignan, Clément Lussier, both tool makers, and Lise Bessette, housewife, wife of said Clément Lussier, the latter two of 1103 Gladu, Muricville, for the following purposes: To manufacture mid deal in metals of all kinds, their products and by-products, under the name of \"Cliambly Mould & Die Inc.\", with a capital stock divided into 5,000 common shares without nominal value and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Cliambly, judiciul district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 3384-1970 La Clinique de Médecine fumilialc il' \\linn inc.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters paient, beuring dale the 18th day of June, 1970, have been issued by the 5200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n\" 88 il n accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de juin 1970, constituant en corporation: David Katznelson, 5526, avenue Ashdulc, Cote Saint-Luc, Robert Litvack, 590, Stanstead, .Mont-Royal, et Ralph Lippcr, 1550, avenue McGregor, Montréal, tous trois uvocats, iMiur les objets suivants: Etablir et diriger une ou plusieurs cliniques de médecine et de chirurgie, sous le nom dc « La Clinique dc Médecine familiale d'Alma inc.», avec un capital total dc 540,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.loration is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2609-1970 l.e Club de Ski le Petit Chumonix Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de juillet 1970, constituant en corporation -.ans capital-actions: Jean Poirier, Jcan-Mauriiv Cyr, tous deux marchands, J.-André Beaulicu, grossiste, Charles Normandeau, superviseur, Puul LeBlanc, médecin, tous cinq dc Siiiiil-Liiurent-de-Matapédia, Gérald Boudreau, marchand, Saint-François-d'Assisc, et Robert-J.Levesque, secrétaire, Saint-Alcxis-de-Matapédia, pour les objets suivants: Promouvoir le ski, sous le nom de « Lc Club de Ski le Petit Chamonix ».Le montant auquel est limitée la valeur îles biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8200,000.l.o siège social de la corporation est n Saint-¦auro:it-dc-Matapédia, district judiciaire dc noiiavcnturc.Le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, ,\u201e\u201e, Ls-Philippe Bouchard.*234-o 3241-1970 Lc Club île Ski le Petit Chamonix Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives to ineori>oratc a corporation without share capital: Jean Poirier, Jean-Maurice Cyr, both merchant, J.-André Beaulicu, wholesaler, Charles Normandeau, supervisor, Paul LcBlanc, physician, all five of Saint I.au-rent-dc-Mntapédia, Gérald Boudreau, merchant, Saint-François-d'Assisc, ami Robert-J.Levesque, secretary, Saint-Alexis-dc-Matapédia, for the following purposes: To promote skiing, under the name of \"Ix Club de Ski le Petit Chamonix\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess is 8200,000.The head office of the corporation is at Saint-Lnurent-dc-Mutapédia, judicial district of Bona-venturc.Ls-Philippi: Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 3241-1970 5262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 .septembre 1970, 102' année, u.\" .-1- Lc Club lu Rencontre de Mont-Joli, inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour dc juillet 1!)70, constituant en corporation sans capital-actions: Maurice Foster, rentier, 27, Sle-Maric, Price, Colette DeCourval, ménagère, épouse de Fcrnand Ruest, Saint-Anaclct, Fcrnand Boudreau, professeur, Causapscal, Raymond Vaillancourt, étudiant, 90, Doucet, et Albert Cimon, prêtre, ces deux derniers de Mont-Joli, pour les objets suivants: Etablir et administrer un club religieux dans le but de promouvoir l'apostolat des laïcs dans l'église, sous le nom dc « Lc Club la Rencontre de Mont-Joli, inc.».Lc montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 520,000.Le siège social de la corporation est à Rimouski, district judiciuirc de Rimouski.Le sous-ministre (les iiutilulioilê financières, compagnies cl cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 2743-1970 Club optimiste du Plateau Mont-Royal, Québec inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Armand Ricndeau, gérant, 10105, Larose.J.-Cillcs Prattc, publicitaire, 5212, Cartier, et Conrad Toucbette, opticien, 1497, St-Joseph est, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux et spécialement aux petits gars nécessiteux et aux délinquants juvéniles, sous le nom de « Club optimiste du Plateau Mont-Royal, Québec inc.».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir cl posséder la corporation, est de $50,000.I/C siège socinl «le la cor|>oration est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalires, Ls-Piiiuppe Bouchard.36234-0 358-1970 Lc Club In Rencontre dc Mont-Joli.inc.Notice is given that under Part III ol the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com.panics and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Maurice foster, annuitant, 27 Slc-Maric, Price, Colette DeCourval, housewife, wife of Fcrnand Rucsl, Saint-Anaclct, Fcrnand Boudreau, professor, Causapscal, Raymond Vaillancourt, student, 90 Doueel, and Albert Cimon, priest, the latter two of Mont-.loli, for the following purposes: To establish and direct a religious club In order to promote the apostolate of laymen within the Church, under the name of \"Ix; Club lu Ren-contre dc Mont-.loli, inc.\".The amount to which is limited the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire and possess is S'il 1,0110.The head office of the corporation is at Ri.mouski, judicial district of Rimouski.Ls-Pimuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.30234 2743.1970 Club optimiste du Plateau Mont-Kuyal, Québec inc.Notice is given that under Part III of Hie Companies Act, letters patent, bearing dale the 23rd day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a eor|>ora-tion without share capital: Armand Hiemlean.manager.10105 Larose, J.-Gillcs Prattc, publicist, 5212 (\"artier, and Conrad Touchctle, optician, 1497 St-Joseph East, all three of Montreal, for the following purposes: To help the poor and the needy ami specially nci'dy young lads and juvenile delinquents, under the name of \"Club optimiste du Plateau Moat-Royal, Québec inc.\".The amount to which is limited the value of llie immovable property which the corporation may acquire and possess is $50,000.The head office of the corporation is al Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234 358-1970 Club Plein Air Spec ino.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives «lonne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en «latc du 7e jour d'avril 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Armunzo Laprisc, oi)éra-teur, 1062, Cartier, Yvon Charticr, analyste, 163, Broadway, app.5, et Fcrnand Boisson-neault, ajusteur mécanique, 643, des Cèdres, tous trois dc Shawinigan, pour les objets suivants: L'organisation «les loisirs, sous le nom «le * Club Plein Air Spec inc.».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc $25,000.Club Plein Air Spec inc.Notice is given that under Part III \"f \"lf Companies Act, letters patent, bearing dale the 7th day of April, 1970, have been issued by 11» Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Armanzo Laprisc, open* tor, 1062 Cartier, Yvon Chartier, analyst, lw Broadway, Apt.5, and Fcrnand Boissoimcanjt, metal fitter, 643 des Cèdres, all three of Si.awini-gan, for the following purposes: The organization of rccrcationul acliyiliçs, under the name of \"Club Plein Air Spec inc.\u2022 The amount to which is limited the value of the immovable property which the corpora I iot may acquire and possess is $25,000.J QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5263 I .¦ siège social dc la corporation est à Shawini-gun, district judiciaire de Saint-Maurice./.,.tous-ministre del institut ions financières, compagnies et cooperatives, Ls-PlllMPPE BoUCHAHI).30234-0 1467-1970 I.u compagnie des grossistes en alimentation inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coo|x-rativcs donne avis, qu'en vertu delà première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de juillet 1970, constituant en corporation : Gustave l'aquin, grossiste, 419, Grande-Allée, Saiul-Jérôme, Denise Tessicr, secrétaire, fille majeure.232, Haniford, et Willord M.C.Stecves, avocat.7S, Providence, ces deux derniers de La-eliulc.pour les objets suivants: Agir comme grossistes en alimentation, sous lc nom de « La compagnie des grossiste en alimentation inc.», avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires snns valeur nominale et en 500 actions privilégiées dc S100 chacune.l.e siège social dc la compagnie est 4955, Cour-trai.Montréal, distiict judiciaire dc Montréal.l,c tons-ministre des institutions financières, .compagnies et coopératives, I .s-Pi i i i,i ppe Bouch ah n.36234-0 2478-1970 The head office of the corporation is at Sliawi-n i gan.judicial district of St.Maurice.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.30234 36234 Lu compagnie des grossistes en alimentai ion inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|x?rativcs, incorporating: Gustavo Paquin, wholesaler, 419 Grande-Allée, Saint-Jérôme, Denise Tessicr, secretary, spinster of the full age of majority, 232 Hamford, and Willnrd M.C.Sleeves, advocate, 78 Providence, the latter two of Lachutc, for the following purposes: To act as food wholesalers, under the name of \"La compagnie des grossistes en alimentation inc.\", with a capital stock divided into 1,000 common shares without nominal value and into 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 4955 Courtrui, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.3G234 2478-1970 < Mil-i i lie i il.Il l!i .lllllic 11 ltéc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour de juillet 1970, constituant en corporation: David Goldenblalt, 3500, Mountain, #67, Donald W.Seal, 3435, Drummond, #12B, tous deux de Montréal, et Paxil Nadlcr, 900, Rockland, \u2022400.Oiitremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir constructeurs et entrepreneurs, sous le nom de « Construction licaubien Itée », avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 39,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.fa sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppe Bouchard.36234 2892-1970 Construction Bcatihicii Itée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Goldenblalt, 3500 Mountain, #67, Donald W.Seal, 3435 Drummond, #12B, both of Montreal, and Paul Nadler, 900 Rockland, #405, Outremont, all three attorneys, for the following purposes: To carry on business as builders and contractors, under the name of \"Construction Beaubien Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of SI each and 39,000 preferred shares of $1 each.The bead office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-0 2892-1970 Constructions Marmico inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour i!c juillet 1970, constituant en corporation: Michel Frenctte, homme d'affaires, Notre-Damc-dc l'ortncuf, Marcel Frenctte, ingénieur, et Monique D.Frenctte, ménagère, épouse dudit Marcel Frcnette, ces deux derniers de 3003, alatapédia, Sainte-Foy, pour les objets suivants: l'aire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce dc toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Constructions Marmico inc.», avec un capital total dc «0,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $10 chaume.Constructions Marmico inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28tb day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Frenetic, businessman, Notrc-Damc-dc-Portncuf, Marcel Frenettc, engineer, and Monique D.Frcnette, housewife, wife of said Marcel Frcnette, the latter two of 3003 Matapédia, St.Foy, for the following purposes: To carry on business as general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Constructions Marmico inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 1,000 preferred shares of $10 each. 5264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 38 Ix siège social de la compagnie est ù Notre-Dnme-de-Portncuf, district judiciaire de Québec.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3G234-0 3239-1970 i/cs couvre plunchcrs Quehar inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour dc juillet 1970, constituant en corporation: Jacques Barsalou, entrepreneur, 348, boulevard Hébert, Salaberry-de-Valleyficld, Guy Gervais, avocat, 565, avenue Berwick, Mont-Royal, et Jacques Godin, vendeur, 1303, Desormeaux, Longucuil, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de meubles, tapis, tuiles et couvre-plancher dc toutes sortes, sous le nom de « Les couvre planchers Qucbar inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 500 actions ordinaires dc 81 chacune, 500 actions privilégiées classe « A » dc SI chacune et en 390 actions privilégiées classe « B » dc 8100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est 32, rue Stc-Cécilc, Salaberry-de-Vallcyfield, district judiciaire dc Bcauharnois.Lc sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives.Lh-Piiilippe Bouchard.30234-o 3059-1970 The head office of the company is al Notre-Damc-de-Portneuf, judicial district of Québec, Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires 36234 3239-1970 Les couvre planchers Quehar in .Notice is given that under Part 1 of i\\K Companies Act, letters patent, bearing dale the 15th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Barsalou, contractor, 348 Hébert Boulevard, Sala-herry-dc-Vallcyficld, Guy Gcrvais, advocate, 565 Berwick Avenue, Mount Royal, and Jacques Godin, salesman, 1303 Desormeaux, Longucuil, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture, carpets, tiles and floor coverings of all kinds, under llie name of \"Les couvre planchers Qucbar inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 500 common shares of 81 each, 500 class \"A\" preferred shares of 81 each and 390 class \"It\" preferred shares of 8100 each.The head office of the company is al 32 Ste-Cécilc Street, Salaberry-dc-Vallcyfield, judicial district of Beauharnois.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institut ions.Companies and Cooperalires.36234 3059-1970 Les Dames auxiliaires du Foyer des Années d'Or dc Kéiiogami inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie dc la Ixri des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour dc mai 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Lili Larouche, épouse dc Marccllin Oucllet, 23, Bourassa, Gertrude Durand, épouse de Roland Pedneault, 246, Ste-Famillc, et Pierrette Maltais, épouse de Joseph-Henri Gagnon, 1, Radin, toutes trois ménagères, dc Kénogami, pour les objets suivants: Promouvoir le bien-être du Foyer tics Années d'Or dc Kénogami, dc ses pensionnaires et résidents, sous le nom dc « Iaîs Dames auxiliaires du Foyer des Aimées d'Or dc Kénogami inc.».Lc montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 810,000.Lc siège social dc la corporation est à Kénogami, district judiciaire de Chicoutimi.Àc sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Ls-Philippe Bouchard.36234-o 2037-1970 Dclmar Forwarding Corp.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3c jour dc juin 1970, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, avenue Claremont, Wcstmount, Oscar Respitx, 4945, avenue Glen-cairn, Montréal, et Sydney B.Sederoff, 80, avenue Crestwood, Montréal-Ouest, tous trois avocats, pour les objets suivants: le- Dames auxiliaires du Foyer des Années d'Or dc Kénogami inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 12th day of May, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incoriwratc a corporation without share capital: Lili Larouche, wife o( Marccllin Ouellet, 23 Bourassa, Gertrude Durand, wife of Roland Pedneault, 246 Sic-Famille, and Pierrette Maltais, wife of Joseph-Henri Gagnon, 1 Radin, all three houscwifes, of Kénogami, for the following purposes : To promote the welfare of the Foyer des Années d'Or de Kénogami, its pensionners and residents, under the name of \"Les Dames auxiliaires du Foyer des Années d'Or de Kénogami inc.\".The amount to which is limited the immovable property which the corporation may acquire and possess is 810,000.The head office of the corporation is al Kénogami, judicial district of Chicoutimi.Ls-Phiuppe Bouchaiiu.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234 2037-1970 Delmar Forwarding Corp.Notice is given that under Part 1 of tlie Companies Act, letters patent, bearing date the 3rd day of June, 1970, have been issued by I* Minister of Financial Institutions.Compuuei ami Cooperatives, incorporating: Mnx S.Kaufman, 574 Claremont Avenue.Wc-i mount.Oscar Rcspitz, 4945 Glencairn Avenue.Montreal, and Sydney B.Sederoff, 80 Crestwood Avenue.Montreal West, all three advocates, for tlie following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5265 Établir et diriger une compagnie de transport, s(\u201eis |(.nom de « Delmur Forwarding Corp.», ave un capital total de 840.000.divisé en 10,000 actions elas.se «A» «le SI chacune, 10.000 actions classe « B » «le SI chacune et 200 actions privilégiées do $100 chacune.I.c siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.,¦ miix-niiiiietre des institutions financière», compagnies et cooperalires, Ls-Piiilippe Bouchard.30231 2459-1970 Diako & Sons Maintenance Company Limited ' I.c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île lu première partie dc la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 10c jour île juillet 1970.constituant en corporation: Karl S.Cohen.4919, Montcluir.Douglas L.Pascal.5392, Prince de Galles, et Theodore H.Shapiro.5175.chemin dc la Côte Saint-Luc, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: l'aire affaires en offrant et fournissant des services d'entretien, sous lc nom de « Diako & Soii> Maintenance Company Limited », avec un capital total de S40.000, divisé en 10.000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.I.c siège social de la compagnie est au 120, lYiiilciinis Drive.l'ointe-Claire, district judiciaire de Monlréal.Usons-ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Pi11lippe Bouchard.3023-1 2983-1970 Jean Dieairc inc.I.c ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il u accorde des lettres patentes, en date «lu 3e jour d'avril 1070, constituant en corporation: Pierre Baillargcon, contrôleur, 2444, Benny Crescent, npp.500, Jean-Paul Rallié, 11707, Alexandre Lacoste, tous deux de Montréal, Jean Dieairc.710.38c avenue, tous lieux pharmaciens, il Jolfrc Côté, courtier d'assurance, 724, 38c avenue, ces deux derniers de Lacbilic, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce en gros de spécialités médicales et de préparations pharmaceutiques et médicales de toutes sortes, sous le nom ih- i Jean Dieairc inc.», avec un capital total d,.$40,000, divisé eli 20,000 actions classe * A de $1 chacune cl en 20,000 actions classe « H de SI chacune.I/- -Hgc social de la compagnie est 815.rue Provost, Lachine, district judiciaire de Montréal.h tous-ministre des institutions financières, compagnie» et coopérative», , Ls-PlllUPPE Bouchard.30234m 1421-1970 Diissault & I .anion, eux (1970) inc.Le ministre des institutions financières, com-WPilcs cl coopératives donne avis, qu'en vertu |e la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du * jour de juillet 1970, constituant en eorpora-noii: (.«slon Mailhot, ingénieur, 1195, Laurier, «ques Lafontaihe, notaire, 2805, Girouard, To carry on the business of transport company, under the name of \"Delmar Forwarding Corp.\", with a total capital slock of $40.000, divided into 10.000 class \"A\" shares of SI each, 10.000 class \"B\" shares of $1 each and 200 preferred shares of $100 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.30231 -o 2459-1970 Diuko & Sons Maintenance Company Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 101 h day of July, 1970.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Karl S.Cohen, 4919 Monlclair, Douglas L.Pascal, 5392 Prince of Wales, and Theodore H.Shapiro, 5175 Cote St.Luc Road, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of providing and furnishing maintenance services, under the name of \"Diako & Sons Maintenance Company Limited\", with a total capital stock of $40.000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head ollice of the company is at 120 Pciideiinis Drive, Pointe-Claire, judicial district of Montreal.Ls-PlllUPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérative».30234-o 2983-1970 Jean Dicaire inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 3rd day of April, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Baillargcon.inspector, 2444 Benny Crescent, Apt.500, Jean-Paul Rathe, 11707 Alexandre Lacoste, both of Montreal, Jean Dicaire, 710, 38th Avenue, both pharmacists, and Joffre Côté, insurance broker, 724, 38th Avenue, the latter two of Lachine, for the following purposes: To manufacture and deal wholesale in medical specialties and pharmaceutical and medical preparations of all sorts, under the name of \"Jean Dieairc inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 class \"A\" shares of $1 each and into 20,000 class \"B\" shares of $1 each.The head olfiec of the company is at 815 Provost Street, Lachine, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.30234 1421-1970 Dussaull & I .a n i d u re u.\\ (1970) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating:Gaston Mailli.it, engineer, 1195 Laurier, Jacques Lafontainc, notary, 2805 Girouard, Kurt W.Hccké, indus- 52GG GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 septembre 1070, 102' année, n° 3H Kurt W.Hccké, industriel, 875, Tcllicr, Andrée Halle, ménagère, veuve dc Louis-Philippe Lafontainc, 2275.Léon-Pratte, tous quatre de Saint-Hyacinthe, Lambert Hébert, homme d'affaires, 249, Principale, Saint-Damasc, Jean-Pierre Gau-vreau, ingénieur, 1120.Crevier, La Providence, et Cannelle Prédette, ménagère, veuve de Georges Cliapdeleinc.1300.Carillon, Douville, poulies objets suivants: Paire affaires comme maîtres de forge, fondeurs et ouvriers en métaux, sous le nom de « Dussuult & Lamourcùx (1970) inc.».avec un capital total de 899.840, divisé en 840 actions ordinaires de SI chacune et en 990 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 7750, rue Broiiillclte, Saint-Hyacinthe, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-mi n istre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ii'i'k Bouchard.30234-o 2930-1970 Echohamok lue.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc lu troisième partie de la Loi des compagnies, il a acerrdé des lettres patentes, en date du 18c jour de juin 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques Drouin, étudiant, Roger Levasseur, infirmier, et Marcel Simnrd, comptable, tous trois de Beaupré, pour les objets suivants: Promouvoir le sport de canoé-kayak, du camping et de la voile, sous le nom île « Echohumok Inc.».Lc montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 850,000.Le siège social de la corporation est à Beaupré, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 2071-1970 Entrepôt des aubaines CM.inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coo|)éralives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27e jour rate a corporation without share capital: Jacques Drouin.student, Roger Levasseur, male nurse, ami Marcel Simard, accountant, ull three of Beaupré, for the following purposes: To promote canoe-kayak, camping and -ailinf, under the name of \"Kchohamok Inc.\".The amount to which is limited the value ol immovable properties which the cor)>oratiea may acquire and hold is 850,000.The head office of the corporal ion is at lieaupré, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchaiiu.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.30234 2071-1070 lint repôt des aubaines CM.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing 'late the 27th day of July, 1970, have been i*ued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice .Maréchal, merchant, Jean-Guy Maréchal, clerk, both of 4000 Place Chfttenuguay, and Chmfc Ouellcttc, assistant manager, 1889 Sl-Olivier.all three of Trois-Rivières, for the following purposes: To manufacture anil deal in furniture ami novelties of all kinds, under the name of Entrepôt des aubaines CM.inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,001) eoinnion shores of $10 each and into 2,000 preferred shtru of $10 each.The head office of the company is ut 76S0 Stc-Marguerite Road.Trois-Rivièrcs.judical district of Three Rivers.Ls-Pi11lippe Boi'ci11aii11.Deputy Minister of Financial Inst il niions, Companies and Cooperalittt.36234 2939-1971 Les entreprises Lacharité Itcc Notice is given that under Part I ol 'J* Companies Act, letters patent, bearing dale the 19th day of June, 1970, have been issued by U\" J QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5287 il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de juin 1970, constituant en corporation: pierre l.nchnrilé, dessinateur, Rietta I.amon tapie, ménagère, épouse dudit Pierre Lacharité, tous deux de 995, Jean dc Brébcuf, Drummond-vilîc-Sud, et Micheline Beaudoin, secrétaire, fille majeure, 552-D, Lindsay, Druniinondville, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d immeuble ot de construction, sous le nom dc « Les entreprises Lacharité Itée», avec un capital total de $10,000 divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc SI chacune et en 390 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune., Le siège social de la compagnie est à Drum-mondville-Sud, district judiciaire dc Drummond./.,¦ sous-ministre des institutions financière!, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 2713-1970 1 .111 i [ 11 -1111 - d i lu -lin limitée Le ministre des institutions financières, com-liagiiics et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 5e our de juin 1970, constituant en corporation: teal llrochu, camionneur, Joseph-Kdinond Roy, I Paul Robcrge, ces deux derniers commerçants, Unis Irois de Saint-Henri, pour les objets suivants: \u2022aire affaires comme garagistes et faire le com-Bcrcc d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de < Equipement By-Ro limitée », avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires le 8100 chacune.l.e siège social dc la compagnie est à Saint-Henri, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre dés institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniUPPB Bouchard.56234-0 2521-1970 Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Lacharité, draftsman, Rietta Lamontagnc, housewife, wife of said Pierre Lacharité, both of 995 Jean de Brébcuf, Dnimmondville South, and Micheline Beaudoin, secretary, spinster of the full age of majority, 552-D, Lindsay, Dnimmondville, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Les entreprises Lacharité Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 390 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Dnimmondville South, judicial district of Drummond.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2713-1970 Équipement By-Ro limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|>cratives, incorporating: Real Brochu, trucker, Joseph-Edmond Roy, and Paul Robcrge, the latter two traders, all three of Saint-Henri, for the following purposes: To carry on business as garage keepers, and to deal in automobiles, motors, machines and all their parts and accessories, under the name of \"Équipement By-Ro limitée\", with a total capital stock of 540,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at Saint-Henri, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives.3G234 2521-1970 Ever Klin International Heated Wipers Inc.Ever Klin International Heated Wipers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e our de janvier 1970, constituant en corporation: Terre Thibault, vendeur, 1135, Sherbrooke, app.5.Jean-Claude Blcau, 10370, Place Taché, tous deux dc Montréal, et Jeun-Paul Importe, 133, nulcyard St-Jcan, Pointe Claire, ces deux derniers industriels, pour les objets suivants: l'aire affaires comme électriciens et fabriquer et aire le commerce de toutes sortes d'appareils et icccssoircs électriques, sous le nom «le « Ever Mm International Heated Wipers Inc.», avec ni capital total de 840,000, divisé en 3,000 actions «unaircs de S10 chacune et en 1,000 actions amlégiécs de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montrai, district judiciaire de Montréal, 'c mu-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, u-.,, Ls-Philippe Bouchard.\",2il\" 330-1970 Félix Auto Service Inc.Le ministre des institutions financières, com-[agmi s et coopératives donne avis, qu'en vertu .toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu dc ladite première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois, sous le nom dc « I.IL Normick inc.» avec un capital de $300,000 «ivise en 300,000 actions ordinaires, dc la valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à La «rrç, district judiciaire d'Abitibi.u m>- \"'1 \" f*f» des institutions financières, compagnies et coopératives, mm, Ls-Philippe Bouchard.*234-o 2324-70 Olympic Helicopters Limited Hélicoptères Olympiques limitée '\u2022c ministre des institutions financières, com-Wies et coopératives donne avis, qu'en vertu 'a premiere partie dc la Loi des compagnies, Miller & Morris Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating : James Brian McMullan, 4014 Marcil Avenue, Jean-Charles Hamclin, 5369 dc Lorimicr, both of Montreal, and Arnold Beaumont Sharp, 1000 Moncrieff, Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as agents and insurance brokers, under the name of \"Miller & Morris Inc.\", with a capital stock divided into 20,000 common shares without par value and 550 preferred shares of the par value of 8100 each.The head office of the company is at Gaspé, judicial district of Gaspé.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-o 3032-1970 Gérard Morin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of July, 1970, have l>ecn issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yvan-M.St-Onge, advocate, Lucie St-Ongc, telephone operator, wife of said Yvan-M.St-Ongc, both of 82 Main, and Come Poulin, advocate, 15 Guy, all three of Granby, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Gérard Morin inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 408 St-Jean Street, Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234 2885-1970 J.H.Normick inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of May, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives authorizing the amalgamation of \"H.Perron & Fils inc.\", incorporated by letters patent dated May 30, 1909, an«l \"J.II.Normick Itée\", incorporated by letters patent dated February 13, 1956, the a foremen Honed letters patent having been issued in accordance with the Purt I of the Companies Act, for the following purposes: The lumber trade, under the name of \"J.H.Normick inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 300,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at La Sarre, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2324-70 Olympic Helicopters Limited Hélicoptères Olympiques limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of June, 1970, have been issued by the 5282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 38 il a accordé de* lettres patentes, en date du 30e jour de juin 11)70, constituant en corporation: Morton Hell, 701.Bertrand Circle.Saint-Laurent.Stanley Cytrynliauni.234.Sheraton Drive.Montréal-Ouest, et Stephen Harper.1212 ouest, avenue des Pins, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir, maintenir, exploiter et affréter des services réguliers (ou autres) d'hélicoptères ou d'autres appareils aériens à ailes rotatives, sous le nom de * Olympic Helicopters Limited \u2014 Hélicoptères Olympiques limitée », avec un capital total de 840.000, divisé en 500 actions ordinaires de 810 chacune.500 actions privilégiées classe « A » de 810 chacune et 300 actions privilégiées classe « B» dc 8100 chacune.Lc siège social dc la compagnie est au 1850.boulevard Laurcntien.Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Lc sous-miuislic des institutions financières.compagnies et cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.30234 2858-1970 Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, incorporating: Morton Hell, 701 Bertrand Circle.Saint-Laurent, Stanley Cylryn-baum, 234 Sheraton Drive.Montreal West, and Stephen Harper, 1212 Pine Avenue \\Vesl, Mont-real, all three advocates, for the following purposes: To establish, maintain, operate and charter regular or other services of helicopters or oilier types of rotating wing aircraft, under I In- naine of \"Olympic Helicopters Limited \u2014 Hélicoptères Olympiques limitée\", with a total capital spick of 810.000, divided into 500 common shares ol 810 each.500 class \"A\" preferred shares of sin each and 300 class \"H\" preferred shares of S|(J0 each.The head office of the company is al ]SÔ0 Laurentian Boulevard, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchaiiu, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.30234-o 2858-1970 Papier Lignery inc.Ligncry Paper Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 11c jour dc juin 1970, constituant en corporation: Damnsc Brisselte, avocat, 243, Marie-Rose, Longucuil, Céline Pépin, fille majeure, 205, De Guyenne, Saint-Lambert, et Lise Pigeon, épouse de Robert Pépin, 378, Petit Coteau, Ycrchères, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Faire alfaircs comme imprimeurs, éditeurs, éditeurs de journaux, lithographes, graveurs, relieurs, libraires, fondeurs de cractères et agents dc publicité, sous le nom dc « Papier Lignery inc.\u2014 Ligncry Paper Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de $5 chacune, 20,000 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale dc SI chacune et en 10.000 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale , avec un capital total de S40.000, divisé en -1,0011 actions ordinaires de $10 chacune.Lc siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.ksiiiis-miiiisiredes institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3023-1 3200-1970 Polygesco Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu le la première partie de la Loi des compagnies, a accordé des lettres patentes, en date du 20e jour de juillet 1970, constituant en corporation: Louis Doripn, Pierre Jolin, tous deux avocats, Claude Champoux, et Rosaire Vallièrcs, ces deux derniers étudiants en droit, tous quatre de 80, St-Pierrc, Québec, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, sous le nom «le « Polygesco Inc.», avec un capital total dc S300.000, divisé en 200 actions ordinaires d'une valeur nominale de $100 chacune, 1,000 actions privilégiées de classe « A» d'une valeur nominale dc $100 chacune et en 1,800 actions privilégiées dc classe « B » d'une valeur nominale de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.'utout-viinislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.2711-1970 divided into 20,000 common shares of $1 each an«l 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at Anjou, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-0 2493-1970 Placements Bo-Vi Itée Bo-Vi Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Max S.Kaufman, 574 Clarcmont, Westmount, Sydney B.Scderoff, 80 Crcstwood, Montreal West, and Philip Shugar, 6267 Macdonald, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Placements Bo-Vi Itée \u2014 Bo-Vi Investments Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head ollice of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-0 3200-1970 Polygesco Inc.Notice is given that untler Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 20th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Louis Dorion, Pierre John, both advocates, Claude Champoux and Rosaire Vallièrcs, the latter two law students, all four of 80 Saint-Pierre, Québec, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Polygesco Inc.\", with a total capital stock of $300,000, divided into 200 common shares of a nominal value of $100 each, 1,000 class \"A\" preferred shares of a nominal value of $100 each and 1,800 class \"B\" preferred shares of a nominal value of 8100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2711-1970 les prêts économiques Mont-Rolland inc.Les prêts économiques Mont-Rolland inc.\u2022c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu * la première partie de la Loi des compagnies, »_ a accordé des lettres patentes, en date du r l°\"r \"c juillet 1970, constituant n corpora-i'°n: Uy Desjardins, boulanger 123, de la Montagne, Jean-Louis Boyer, commis, 158, M-l.eorges, Jean-Paul Charettc, journalier, 205, JiTO.JWdy Schultz, soudeur, 238, St-Joseph, Wrald Desjardins, marchand, 233, St-Joseph, suc .Mont-Rolland, pour les objets suivants: rare affaires comme compagnie d'immeuble, [ construction et de placement, sous le nom de Pr6ls .économiques Mont-Rolland inc.», v« un capital total de $80,000, divisé en 600 tt< loir le Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Guy Desjardins, baker, 123 de la Montagne, Jean-Louis Boyer, clerk, 158 St-Georges, Jean-Paul Cha-rette, labourer, 205 St-Joseph, Eddy Schultz, welder, 238 St-Joseph, and Gérald Desjardins, merchant, 233 St-Joseph, all of Mont-Rolland, for the following purposes: To do business as a real estate, construction and investment company, under the name of \"Les prêts économiques Mont-Rolland inc.\", with a total capital stock of $80,000, divided into 5284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° ,9.9 actions ordinaires de 8100 chacune et en 200 actions privilégiées dc 8100 chacune.Lc siège social de la compagnie est 123, rue dc la Montagne, Mont-Rolland, district judiciaire de Terrebonne.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiui'pe Bouchard.3G234-0 2447-1970 Québec Automotive Industries Limited Les industries automotrices du Québec limitée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de juillet 1970, constiuunt en corporation: Jerome Christopher Smyth, 04, Roselawn Crescent, John Ralph Hannan, 125, avenue Balfour, Pierre Boudrcault, 231, avenue Lazard, Colin David Blakely, 85, avenue Brittany, app.510, tous les quatre dc Mont-Royal, Douglas Scott Prydc, 4569, avenue Iiingston, et Mary Hcrzbcrg, fille majeure, 1230, rue McGregor, app.301, ces deux derniers de Montréal, tous les six avocats, pour les objets suivants: S'établir garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et toutes les pièces et accessoires connexes, sous lc nom de « Québec Automotive Industries Limited \u2014 Les industries automotrices du Québec limitée », avec un capital divisé en 1,000 actions sans valeur nominale ou valeur au pair.\\x siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.36234 3191-1970 Québec aulorama inc.I.i- ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9c jour de juillet 1970, constituant en corporation: Luigi Pasquini, marchand, 2353, L.-O.David, Montréal, Lucien Richard, vendeur, et Lucille Bcaudry, secrétaire, épouse dudit Lucien Richard, ces deux derniers dc 188, De Brullon, Bouclier vil le, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire lc commerce d'automobiles et autres véhicules motorisés et tous leurs accessoires et parties, sous le nom dc « Québec autorama inc.», avec un capital total de 820,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc 81 chacune et en 10,000 actions privilégiées de 81 chacune.Ix! siège social dc la compagnie est 2353, rue L.-O.David, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 2959-1970 Quincaillerie la Péradc inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour de juin 1970, constituant en corporation: Jean-Pierre Lc Houillicr, analyste, 95, Beauri-vage, L'Assomption, Charlemagne Le Houillier, 600 common shares of S100 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 123 delà Montagne Street, Mont-Rolland, judicial district of Terrebonne Ls-Philippe Bouchaiiu, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives 36234 2447-1970 Québec Automotive Industries Limited l.e- industries automotrices du Québec limitée Notice is given that under Part I of uV Companies Act, letters patent, bearing dale II» 22nd day of July, 1970, have been issued by tlie Minister of Financial Institutions, Comparât] and Cooperatives, incorporating: Jerome Christopher Smyth, 64 Roselawn Crescent, John Ralph Hannan, 125 Balfour Avenue, Pierre Boudrcault, 231 Lazard Avenue, Colin David Blakely, 85 Brittany Avenue, Apt.510, all four of Mount Royal, Douglas Scott Prydc, 45C9 Iiingston Avenue, and Mary Hcrzbcrg, spinster, 1230 McGregor Street, Apt.301, the latter two of Montreal, all six advocates, for the following purposes: To carry on business as garages-keepers and to deal in automobiles, engines, machines and all their parts and accessories, under the name of \"Québec Automotive Industries Limited\u2014lei industries automotrices du Québec limitée\", with a capital slock divided into 1,000 shares without nominal or pur value.The head office of the company is al Montreal judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234-o 3191-1970 Québec autorumii inc.Notice is given that under Pari I of tlie Companies Act, letters patent, bearing dale the 9th day of July, 1970, have been issued by llie Minister of Financial Institutions.Comparus and Cooperatives, incor|>oruting: Luigi l'asqiiini, merchant, 2353 L.-O.David, Montreal, Lucien Richard, salesman, and Lucille Bcaudry, tary, wife of the said Lucien Richard, the latter two from 188 De Brullon, Boiiehcrville.for the following purposes: To do business as garage-owners ami to deal in automobiles and other motorized vehicles ami all their accessories and parts, under I he name of \"Québec autorama inc.\", with a total capital stock of 820,000, divided into 10.0110 common shares of 81 each and into 10,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at 2.J5Î.L.-0.David Street, Montreal, judicial districts! Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Inst it til ions, 30234 Companies and Coopératif-2959-1970 Quincaillerie la Péradc inc.Notice is given that under Part I of tbt Companies Act, letters patent, bearing date \"v 26th day of June, 1970, have Ih-cii isscd by \"* Minister of Financial Institutions, Company and Cooperatives, incor|x>ruting: Jean-lien* Le Houillier, analyst, 95 Beaurivagc, ^Asson* tion, Charlemagne Le Houillicr, and MicM QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5285 ct Michel Lc Houillier, ces deux derniers machinistes, de llutiscan, pour les objets suivants: Fain affaires comme quincailliers, sous le nom ,|c « Quincaillerie la Péradc inc.», avec un capital total de S 10,000, divisé en 1,200 actions ordinaires ,1c $10 chacune, 1,500 actions privilégiées classe < A ¦ île $10 chacune ct en 1,300 actions privilégiées class « I) » de 810 chacune.l.e siège- social de la compagnie est 160, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade, district judiciaire de Trois-Rivièrcs.le tout-ministre des institutions financières, compagnies et cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 2772-1970 R.D.Design & Seal Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopérative» donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de juillet 1970, constituant en corporation: Richard Dcsharnnis, industriel, 2746, de l'Anse, René Gingras, gérant, 2792, Laprade, tous deux de Saintc-Foy, et Pierre Blouin, avocat, 2000, Royale, Courvillc, pour les objets suivants: Manufacturer et foire lc commerce de produits et marchandises fabriqués totalement ou en partie de métaux ou plastique, sous le nom de «R.D.Design & Seal Inc.», avec un capital total de $-10,000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et en 200 actions privilégiées dc $100 chacune.l.e siège social de la compagnie est 139, rue Commerciale.Saiiit-Jcan-Cbrysostome, district judiciaire de (juébec.lésons-ministre des institutions financières, compagnies el cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 3322-1970 lte-a Inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de juin 1970, constituant en corporation: \\oinc Goldstein, 6505, côte Saint-Luc, Robert Lefcort,__5025.avenue Macdonald, ct Leonard rlanz, 5750, avenue Trinity, tous trois avocats, le Montréal, pour les objets suivants: S'établir appréciateurs ct évaluateurs dc biens jiatcricls, mobiliers ct immobilers, sous lc nom e « Rcsa Inc., avec un capital total de $40,000, «visé en 1.0(H) actions ordinaires d'une valeur «pair de $10 chacune ct 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, wrict judiciaire dc Montréal.ms-minislrc des institutions financières, compagnies et coopératives, \u201e\u201e, 1-s-Philippe Bouchard.6234 2727-1970 Restaurant Beltrano inc.Le ministre des institutions financières, com-«pnes et coopératives donne avis, qu'en vertu f la premiere partie de la Loi des compagnies, a accord,', des lettres patentes, en date du 8c «le juillet 1970.constituant en corporation: w>la Beltrano.55.Wellington nord, Mario » ?\" f -''\"'' KmR ouest- tous deux restaura-w (im,v'n- secrétaire médicale, fille Wre, 002.Courcclctte, tous de Sherbrooke, wfca objets suivants: Lc Houillier, the latter two machinists, of Batis-can, for the following purposes: To carry on business as ironmongers, under the name of \"Quincaillerie la Pérade inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,200 common shares of $10 each, 1,500 class \"A\" preferred shares of $10 each and 1,300 class B\" preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 160 Principal Street, Saintc-Anne-de-la-Pérade, judicial district of Three Rivers.Ls-Fiiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 2772-1970 R.D.Design & Seal Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Dcsharnais, industrialist, 2746 De L'Anse, René Gingras, manager, 2792 Laprade, both of St.Foy, and Pierre Blouin, advocate, 2000 Royale, Courville, for the following purposes: To manufacture and deal in products and merchandise made in whole or in part of metal or plastic, under the name of \"R.D.Design & Seal Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 200 common shares of $100 each and 2C0 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 139 Commerciale Street, Saint-Jean-Chrysostome, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 3322-1970 Rcsa Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yoine Goldstein, 6505 Côte St.Luc, Robert Lefcort, 5025 Macdonald Avenue, and Leonard Flanz, 5750 Trinity Avenue, all three lawyers, of Montreal, for tlie following purposes: To carry on business as appraisers and valuators of physical assets, movable and immovable, under the name of \"Rcsa Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234-o 2727-1970 Restaurant Beltrano inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nicola Beltrano, 55 Wellington North, Mario Beltrano, 2046 King West, both restaurant-owners, and Lise Gauvin, medical secretary, spinster of the full age of majority, 1002 Courcelette, all of Sherbrooke, for the following purposes: 528G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, »° 38 Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Reltrano inc.», avec un capitul total dc 540,000, divise en 400 actions ordinaires dc SI00 chacune.Lc siège social de la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Lc .iou.i-miiii.ilrc des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Pllilippe Bol'cl! ahd.302.34-o 3008-1970 Sabcrtons Card Centre Ltd.Centre de carte Suhcrton Itée Le ministre des institutions financières.Compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la \\a>\\ des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour île juillet 1970, constituant en corporation: Brahm M.(ielfand, 5140, May-fair.Gordon fûigler, 0300, Lennox, tous deux avocats, et Penny Coley, secrétaire, fille majeure.1422, Marcil, tous les trois de Montréal, pour les objets suivants: S'établir imprimeurs, lithographes et éditeurs, sous le nom de « Sabcrtons Card Centre Ltd.\u2014 Centre de carte Suhcrton Itée », avec un capital total dc S40.000.divisé en 10.000 actions ordinaires de 51 chacune et 30.000 actions privilégiées *J sociation des Bibliothèques Municipale» Québec inc.\", incorporated by letters paU» the 3rd day of June 1959, changing ils nanxi QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5291 nom on celui de « L'Association des Bibliothèques Publiques ct des Centres Culturels tlu Québec inc.»., ., , Le sous-secrétaire de la province, Raymond Douville.3023-1-o 13104-59 L'Auberge (St-Jérôme) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ol coopératives donne avis, qu'en vertu ile In troisième partie de la Loi des compagnies, il n accorde des lettres patentes supplémentaires en dale du 29e jour de juin 1970, à la corporation .L'Auberge (St-Jérômc) inc.».augmentant le moulant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder ladite corporation de SI.000.000 à S3.000.0C0.\\jt saiis-iu in iitre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Pihuppe Bouchard.30234-o 1532-07 Auloski inc.Le ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu île lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en (laïc du 30e jour de juin 1970, à la compagnie \u2022 Auloski inc.».1° convertissant 1,000 actions onlinaires d'une valeur au pair dc 8100 chacune en 1.000 actions ordinaires sans valeur au pair; 2° subdivisant 1,000 actions ordinaires sans valeur au pair en 000.000 actions ordinaires sans valeur au pair; 3° créant 400.000 actions onlinaires sans valeur pourvu que la considéra-lion globule pour l'émission des actions sans valeur nominale n'excède pas $500,000.Ltsoiis-iuiiiistre des institutions financières.compagnies et coopératives, Ls-Piii i.i Boueu au o.30234-n 2845-69 that of \"L'Association des Bibliothèques Publiques et des Centres Culturels du Québec inc.\".Raymond Douville, Assistant Secretary of the Province.36234 13104-59 L'Auberge (St-Jérômc) inc.Notice is given that, under Part III of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29lli day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"L'Auberge (St-Jérômc) inc.\", increasing the amount to which is limited the value of the immovables which the said corporation may acquire or be in possession of from SI .000.000 to S3.000.0C0.Ls-Pl 11 li 1'1'e Bouci iaii1), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 1532-07 Autoski inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30lh day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Autoski inc.\", I.converting 1,000 common shares of a par value of S100 each into 1,000 common shares without par value; 2.subdividing 1.000 common shares without par value into 600.000 common shares without par value; 3.creating 400.000 common shares without value inasmuch as the global consideration for the issuing of shares without nominal value docs not exceed $500,000.Ls-Pi11i.ippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.30234 2845-69 Caprin- Industries and Resources Limited Caprivc Industries and Resources Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ne la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires cri date du 21e jour d'avril 1970, à la compagnie «Caprivc Oil and Cas Company Limited» (No Personal Liability), constituée par lettres patentes cil date du 17c jour d'avril 1957.1° changeant son nom en celui de « 'Caprivc Industries and Resources Limited»; 2° passant de la juridiction delà Loi des compagnies minières à celle de la Loi des compagnies; 3° augmentant le nombre de ses administrateurs de 5 à 7; 4° changeant 0,000,000 actions d'une valeur au pair de SI chacune en 6,000,000 actions sans valeur \"«minale.dont la considération totale sera de Sli,0()0.(l(:(l; 5° étendant ses pouvoirs.usons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, ,.\u201e, Ls-Philippe Bouchard.¦mi-\" 11382-57 Carrière Hébert inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu 11 e la première partie de la Loi des compagnies, a accordé des lettres patentes supplémentaires ™ date du 23e jour de juillet 1970, à la compagnie Varnerc Hébert inc.», étendant ses pouvoirs.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, o.»».J.-Albert Gagnon.\"W34-° 13206-62 Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 21st day of April.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Caprivc Oil and Gas Company Limited\" (No Personal Liability), incorporated by letters patent dated the 17th day of April, 1957.changing its name to that of \"Caprivc Industries and Resources Limited\"; 2.passing from the jurisdiction of the Mining Companies Act to that of the Companies Act; 3.increasing the number of its directors from 5 to 7; 4.changing 6.000,000 shares of a par value of $1 each into 6,000,000 shares without nominal value, the total consideration of which shall be $6,000.000; 5.extending its powers.Ls-Philippe Bouciiaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 113S2-57 Carrière Hébert inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 23rd day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Carrière Hébert inc.\", extending its powers.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.36234 13206-62 5292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, u° 8S Crédit Stanstead inc.Stanstead Credit Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes supplémentaires en date du 26e jour dc juin 1970, à la compagnie « Crédit Stanstead inc.\u2014 Stanstead Credit Inc.», augmentant son capital dc $225,000 à S500.000 par la création dc 1,750 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S100 chacune ct 1,000 actions privilégiées dc $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, Ls-Philippe Bouchard.36234-o 1443-63 Les Cuisines Roi du Nord inc.Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie dc In Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes supplémentaires en date du 8c jour dc juin 1970, à la compagnie « Les Cuisines G.Miller inc.», constituée par lettres patentes en date du 30e jour dc juillet 1963, changeant son nom en celui dc « Les Cuisines Roi du Nord inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopêratires, Ls-PlIILIPPE mouchard.36234-0 3227-63 Despalis Transport limitée Lc ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 12e jour de juin 1970, à la compagnie « Dcspatis Transport limitée », 1° réiluisant son capital dc $50,000 à $34,000 en annulant 1,600 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $10 chacune; 2° refondant 2,400 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune en 480 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 850 chacune; 3° augmentant son capital de.$34,000 à $630,000 par la création de 11,920 actions privilégiées d'une valeur au pair de $50 chacune.Le sous-ministre des institut ions financières, compagnies el coopératives, Ls-Piiimppe Bouchard.36234 1112-63 Duhtic Tank Lines Ltd.Lc ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie dc la Loi «les compagnies, il a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 15e jour de juin 1970, à la compagnie « Dulnic Tank Lines Ltd.», augmentant son capital de $173,000 à $273,000 par la création de 1,000 actions privilégiées «le $100 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.36234-0 14882-62 ¦ Dumonl Express liée Dumont Express Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 21c jour dc mai 1970, à la compagnie « Dumont Express Itée \u2014 Dumont Express Crédit Stanstead inc.Stanstead Credit Inc.Notice is given that, under Part f of the Companies Act, supplementary letters paient, bearing date the 26th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"('redit Stanstead inc.\u2014 Stanstead Credit Inc.\".increasing its capital from $225,000 to $500,001) by the creation of 1,750 common shares of a par value of 8100 each and 1,000 preferred shares of $100 each.Ls-PniLippb Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cobpt ralites.36234 1U3-C3 Les Cuisines Roi du Nord inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent; bearing date the 8th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Los Cuisines (J.Miller inc.\", incorporated by letters patent dated the 30th day of July, 1963, changing iu name to that of \"Les Cuisines Roi du Nord inc.\".Ls-Piiilippe Bouchaiiu.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 36234 3227-63 Dcspatis Transport limitée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 12th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Dcspatis Transport limitée\", 1.reducing its capital from 850,000 to $34,000 by the cancellation ol 1,600 preferred shares of the par value of $111 each; 2.consolidating 2,400 preferred shares of the par value of $10 each into 480 preferred shares of the par value of $50 each; 3.increasing ils capital from $34,000 to $630,000 by the creation of 11,920 preferred shares of the par value of $50 each.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instil niions.Companies and Cooperatives, 36234-0 U12-63 Dubuc Tank Lines Ltd.Notice is given that, unilcr Part I \"f the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 15th day of June.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Public Tank Lines Ltd.\", increasing its capital from $173,000 to $273,000 by the creation of 1,000 preferred shares of $100 each.Ls-Philippe Bouchaiiu.Deputy Minister of Financial Instil niions.36234 Companies and Ccaring date the 11th day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Loignoi & Durand inc.\", incorporated by letters patent dated the 5th day of February 196S, changing its name to that of \"Loignon, Durand & Qucvillon inc.\".Ls-Piiilippe Bouciiaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.36234 479-6$ R.Menard Transport lice Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16c jour de juin 1970, à la compagnie « R.Ménard Transport Itée », augmentant son capital '» day of October, 1961, changing its name to In\" of \"S.O.S.Distribution Inc.\".Ls-Philippe Bouchau;», Deputy Minister of Financial Instil niions, Companies and Coopiralxra-36234 looOiwI QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5297 ( es Sucs à Main Grand Prix inc.Grand Prix Handbags Inc.I.c ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ,|c lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes supplémentaires en date «lu 25e jour de mai 1970, i\\ la compagnie \u2022 Les Sucs à Main Grand Prix inc.\u2014 Grand Prix Handbags Inc.», 1° changeant les droits afférents aux actions privilégiées; 2° augmentant son eapital par la création dc 850 actions privilégiées d'une valeur au pair «le 8100 chacune.U tout-in in istre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38234-0 714-66 Service de Planchers inc.Floor Service Inc.Le ministre des institutions financières, com-j papiies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, | il a accordé des lettres patentes supplémentaires I en date du 18c jour «le juin 1970, à la compagnie < Laforcst Service de Planchers inc.\u2014 Laforest Floor Service Inc.», constituée par lettres patentes en date du 25e jour de mai 1961, chan-I géant son nom en celui de « Service de Planchers inc.\u2014 Floor Service Inc.».Le sous-mi ni si rc des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniuppE Bouchard.130234-.12581-61 Service de Soins à Domicile des I.anient ides inc.Avis est donné qu'en vertu dc la Loi des j compagnies, il a été accordé, par lc licutcnant-Igouverneur de la province, des lettres patentes [supplémentaires en date du 23e jour de juillet 11969, à la - Société des Infirmières Visiteuses du [Diocèse de Si-Jérôme », constituée en corporation jpar lettres patentes du 13e jour «lc mai 1963, [changeant son nom en celui dc « Services dc Soins |àDomicile des Laurentides inc.».Le tout-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.136234-0 2050-63 Service National des Hôtesses inc.National Service of Hostesses Inc.Le ministre «les institutions financières, com-Ipagnios el coopératives donne avis, qu'en vertu I c lu première partie de la Loi des compagnies, V a accordé des lettres patentes supplémentaires pi date du 7c jour d'avril 1970, à la compagnie service National des Hôtesses inc.\u2014National \"mice of I losti'sseslnc.», augmentant son capital «r la création de 7,000 actions privilégiées d'une wur au pair de $10 chacune.tums-minislre des institutions financières, compagnies et cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.16234 4272-69 Simard & Voyer inc.Le ministre des institutions financières, compiles et coo|)ératives donne avis, qu'en vertu «« Première partie de la Loi des compagnies, Les Sacs à Main Grand Prix inc.Grand Prix Handhags Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th réc en vertu de la Loi des compares, ayant son siège social a Rimouski, s'adres-* au ministre des institutions financières, ¦WWes et coo]>ératives, pour obtenir la *nni.vs,o\u201e d ubundonner sa charte, en vertu ^positions de la Loi des compagnies.K'mouski.ce 9 septembre 1970.fin, \u201e procureurs de la compagnie, >w-o Casgrain, Casorain & Crevter.Ouellct ct Labergc Itée Notice is given that \"Ouellet et Laberge ltéc \" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Québec, this 18th day of August, 1970.Me.Cyrille Delâge, notary, 36282 Attorney for the company.Ran Mar Mines Ltd.(No Personal Liability) Notice is hereby given that \"Ran Mar Mines Ltd.\" (No Personal Liability), a company incorporated under the Mining Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 27th day of August, 1970.J.O.Sabourin, 36283-0 Secretary.Les Investissements Rimouski inc.Notice is hereby given that \"Les Investissements Rimouski inc.\", a corporation duly incorporated under tlie companies Act and having its head office in Rimouski, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter, in conformity with the provisions of the Companies Act.Rimouski, this September 9, 1970.Casgrain, Casgrain & Crevier, 36304-o Attorneys to the company. 5306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102- année, n° 88 Sogctrcm Inc.Lu compagnie « Sogctrcm Inc.», constituée en corporation en vertu de la Im des compagnies, et ayant son siège social en la cite dc Ville Mont Royal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daré à Montréal, ce 21c jour dc juillet 1970.Le secrétaire, 36305 Pierre Tremblay.Louis Philippe Racine Démolition inc.Avis est donné que la compagnie « Louis Philippe Racine Démolition inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coo|)érativcs la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce 14 juillet 1970.Les procureurs du requérant, 36323-0 Demers & Gosse lin.Sogctrcm Inc.Notice is given that \"Sogctrcm Inc.\", a coq», ration incorporated under the Companies Act, and having its head office in the city of towitl Mount Royal will apply to the .Minister of Financial Institutions Companies and Coopéra, lives for leave to surrender its charter under 11» provisions of the Companies Act.Dated in Montreal, this 21st day of July, 1970.Pierre Tremulay, 36305-o Secretary.I.nui- Philippe Racine Démolition inc.Notice is given that \"Louis Philippe Racinr Démolition inc.\" will apply to the Minister ol Financial Institutions, Companies and Coopéra, lives, for leave to surrender its charier.Québec, July 14, 1970.Demers & Gosseux, 36323 Attorneys for the Company, Divers\tMiscellaneous Compagnies\tCompanies L'Association Sportive Lanoraic inc.\tL'Association Sportive Lanoraic inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis que le 29 juillet 1970, il a approuvé lc règlement numéro 11 dc la corporation « L'Association Sportive Lanoraic inc.» et ce, en vertu dc l'article 225 dc la loration « La Fédération des Monas-7*?orution par lettres patentes en date du 31e jour de décembre 1956, et ayant son siège social dans la cité dc Québec, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui it 2, Avenue Chauvcau, l'a transporté à 1250, 3e Avenue, Québec.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné a Québec, ce 31e jour de juillet 1970.Le secrétaire, L.Verreault.36267-0 11648-56 Publications Dumont inc.Notice is given that ''Publications Dumont inc.\", bos transferred its head ollice from l.aSalle, to 3136 LaSalle Boulevard, Verdun.3G259-0 Leo Forget, Secretary, \u2022.'51)3-69 À la Cour Mailloux inc.Notice is given that \"À La Cour Mailloui inc\", incorporated by letters patent issued under Part 1 of the Companies Act, on June 29, 1970, and having its head office in Québec, in the district of Québec, has established its office at 9 St-Louis Street, in Québec, district of Québec.From and after the date of this notice, tlie said office is considered by the ra.ted by letters patent dated January 8, 1970 anil having its head office in Montreal, has established its office at number 4824 Côte des Neiges, suite 28, judicial district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Montreal, August 11, 1970.Gilles Élu:, President.36291 0324-69 Ariens Canada Ltd.Aricns Canada ltéc Avis est donné que la compagnie « Ariens Canada Ltd.\u2014 Ariens Canada ltéc » a changé son siège social du 148, rue Saint-Jean, Drum-mondville, à 1405, rue Peel, bureau 300, Montréal.Le secrétaire, Stephen Ariens.36312 779-69 Ariens Canada Ltd.Ariens Canada ltéc Notice is given that \"Ariens Canada bld.\u2014 Ariens Canada ltéc\" has transferred its head office from 148 St-Jcan Street, Drununoudville to 1405 Peel Street, room 300, Montreal.Stephen- Am ens, Secretary, 36312-o 779-69 Les Vieux Noels inc.Christmas Carols Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Vieux Noëls inc.\u2014 Christmas Carols Inc.» a change son siège social du numéro 105, Côte dc la Montagne, Québec, à la suite 760, 220 est, Grande-Allée, Québec.Québec, le 18 août 1970.Le secrétaire, François B.Gravel.36313-0 10397-55 Les Vieux Noëls inc.Christmas Carols Inc.Notice is given that \"Les Vieux Noëls inc.\u2014 Christmas Carols Inc.\" has transferred ils head office from 105, Côte de la Montagne.Québec, to suite 760, 220 Grandc-Alléc, east, Québec.Québec, August 18, 1970.François B.Gravel, Secretary.36313-0 10397-55 R.Gingras & Associés inc.Avis est donné que la compagnie « R.( \u2022 ingras & Associées inc.», constituée en corporation selon la première partie dc la Loi des compagnies en date du 26 février 1970 et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau au numéro 561 Crémazie est, suite 26, Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné ù\\ Montréal, ce 30e jour dc juin 1970.L'officier autorisé, Raymond Ginoras.36315-0 873-70 R.Gingras & Associés inc.Notice is hereby given that \"R.Gingras & Associés inc.\", incorporated by letters patent under Part I on February 26,1970 and having its head office in Montreal, has established ils ollice at 561 Crémazie East, Suite 26, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as lieing its head office.Given at Montreal, this 30th day of June, 1970.' Raymond Gingras, Authorized Officer.36315 87341 René Lcclerc Construction inc.Avis est donné que la compagnie « René Lcclerc Construction inc.», constituée en corporation en date du 29 septembre 1969, a établi son siège social au 5423 de la rue Verncuil, i\\ ville d'Anjou, district dc Montréal.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Ville d'Anjou, ce 21e jour dc juillet 1970.Le secrétaire, Raymonds Cardinal-Leclerc.36316-0 1297-69 René Leclerc Construction inc.Notice is hereby given that the compas} \"René Lcclerc Construction inc.\", incorporated by letters patent on the 29th day of September 1969, lias established its office at number oiu Verneuil Street, in ville d'Anjou, district et Montreal.From and after the date of this notice, IM said office shall be considered by the compas} as being the head office of the company.Dated at ville d'Anjou, this 21st day of JW.1970.Raymonde Cardinal-Le'-lkiic, Secretary' 36316-0 1297* QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5315 Sorcl Investment Corporation Avis est donné que la compagnie « Sorel Investment Corporation », constituée en corporation par lettres patentes en date du 7 juillet i960, ct ayant son siège social dans la cité de Sorci, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 70, rue du Roi, l'a transporté au numéro 54, rue Charlotte.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant -son siège social.Donné à Sorcl, ce 10 juillet 19/0.Le président, Gabriel Germain.36330-e 12786-60 Sorel Investment Corporation Notice is hereby given that \"Sorel Investment Corporation\", incorporated by letters patent on the 7th of July 1960, and having its head office in the city of Sorel, where its office was situated until today, at 70 rue du Roi, has moved it to 54 Charlotte Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office Given at Sorel, this July 10, 1970.Gabriel Germain, President.36330 12786-60 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Samuel Shildkraut Avis est par les présentes donné que Samuel Shildkraut, commis préposé à la production, des ville et district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Samuel Chasen.Montréal, 3 septembre 1970.Les procureurs de Samuel Shildkraut, CitAiT, Salomon, Gelber, Ciaccia Reis 36228-37-2-0 & Bronstein.Margaret Selma Braun Avis est par les présentes donné que Margaret Selma llraim, du 503, rue Cherricr, app.10, Montréal.Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de changer son nom en celui de Margaret Selma Brad, ledit changement ne devant s'appliquer qu'à elle-même.Montréal, le 8 septembre 1970.Les procureurs de la requérante, 36269-38-2 Marks, Shapiro & Wohsoff.Francis Michael Cross Avis est donné que monsieur Francis Michael Cross, opérateur d'ordinateur, domicilié et résidant au 10,363, rue Cobourg, à Montréal-Nord, district de .Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Rodney Malcolm Cross.Montréal, le 12 août 1970.Les procureurs du requérant, im Samson & Tartif.Georges Lorient Gauthier Avis est donné que Georges Lorient Gauthier, domicilié à 88 rue Jacques-Cartier Nord à Farn-nam présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer son nom en Georges Lawrence Gauthier.invm on I'es Vrocurèurs du requérant, JW22-38-2-0 Marquis, Totii & Jutras.Change of name \u2014 Act Applications Samuel Shildkraut Notice is hereby given that Samuel Shildkraut, Production Clerk, of the city and district of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor, in Council, for an order changing his name to that of Samuel Chasen.Montreal, September 3, 1970.Chait, Salomon, Gelber, Ciaccia, Reis & Bronstein, 36228-37-2-0 Attorneys for Samuel Shildkraut.Margaret Selma Braun Notice is hereby given that Margaret Selma Braun, of 503 Cherrier Street, Apt.10, Montreal, Québec, will present to the Lieutenant-Governor in Council an application to change her name to Margaret Selma Brad which change will benefit her alone.Montreal, September 8, 1970.Marks, Shapiro & Worsoff, 36269-38-2-0 Attorneys for applicant.Francis Michael Cross Notice is given that Francis Michael Cross, computer operator, residing and domiciled at 10,363, Cobourg Street, Montreal-North, district of Montreal, shall petition the Lieutenant-Governor in Council to obtain a decree changing his name to Rodney Malcolm Cross.Montreal, August 12, 1970.Samson & Tardif, 36294-0 Attorneys for the petitioner.Georges Lorient Gauthier Notice is hereby given that Georges Lorient Gautliier, residing at 88 Jacques-Cartier Street North at Farnham, will present the Lieutenant-Governor in Council with a request to change his name to Georges Lawrence Gauthier.Marquis, Totii & Jutras, 36322-38-2 Attorneys for the applicant.Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Accordés Granted Jeffrey Noah Asher Jeffrey Noah Asher u lieutenant-gouverneur en conseil, The Lieutenant-Governor in Council has been numéro 3256, du 2 septembre 1970, pleased by Order number 3256 of September 2, 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102- année, n' 38 d'effectuer le changement de nom de Scymorc Jeffrey Itcovitch en celui dc Jeffrey Noah Asher.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Daiiveau, ch., 36303-o Sous-minislre associé de la justice.Robert Emile Rcrnicr Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3252, du 2 septembre 1970, d'effectuer lc changement dc nom dc Joseph Emile Roméo Bcrnier en celui de Robert Emile Bernier.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Daiiveau, ch., 36303-o Sous-minislre associé de la justice.Marie Matildc Paillette Charcttc Il a plu uu lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3263, du 2 septembre 1970, d'effectuer lc changement de nom dc Marie Mathildc Amabilis Charcttc en celui dc Marie Matilde Paillette Charcttc.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Daiiveau, ch., 36303-o Sous-minislre associé de la justice.Chi-Ting-Chcn Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil' par le décret numéro 3257, du 2 septembre 1970> d'effectuer lc changement dc nom de Chui-Ting Wai en celui de Chi-Ting Chen ct de ses deux (2) enfants Marge Wai et Edward Gec-Ging Wai en celui de Marge Chen et Edward Gce-(ïing Chen.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Daiiveau, ch., 36303-o Sous-ministre associé de la justice.Irving Martin Diamond Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil' par le décret numéro 3265, du 2 septembre 1970, d'effectuer le changement de nom de Irving Martin Zucowcn celui dc Irving Martin Diumond.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Darveau, ch., 36303-o Sous-ministre associé de la justice.Eugene Dollin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3260, du 2 septembre 1970, d'effectuer lc changement dc nom dc Eugene Psiuk en celui dc Eugene Dollin.Québec, lc 10 septembre 1970.Lucien Darveau, ch., 36303-o Sous-m in istre associé de la justice.Jack Shin Yick Eng Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3259, du 2 septembre 1970, d'effectuer le changement de nom de Shin Yick Ng en celui dc Jack Shin Yick Eng.Québec, 10 septembre 1970.Lucien Darveau, ch., 36303-o Sous-minislre associé de la justice.Marie Joseph Alfredine Nadine Gagnon Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3258, du 2 septembre 1970, d'effectuer lc changement dc nom de Marie Joseph Alfredine Gagnon en celui de Marie Joseph Alfredine Nadine Gagnon.Quélicc, le 10 septembre 1970.Lucien Darveau, en., 36303-o Sous-ministre associé de la justice.1970, to effect the change of name of Sevan* Jeffrey Itcovitch into that of Jeffrey Noah \\SL Québec, September 10, 1970.Lucien Darveau, q.c, 36303 Associate Deputy Minister of Justice.Robert Emile Bcrnicr The Lieutenant-Governor in Council hushm pleased, by Order number 3252 of September 1 1970, to effect the change of name of Josepl Emile Roméo Bcrnicr into that of Robert fimile Bcrnicr.Québec, September 10, 1970.Lucien Darveau, ij.c, 36303 Associate Deputy Minister of Justice.Marie Matildc Paulcttc Chard te The Lieutenant-Governor in Council has be™ pleased, by Order number 3263 of September 2, 1970, to effect the change of name of Mart Mathildc Amabilis Charcttc into that of Mart Matildc Paillette Charctte.Québec, September 10, 1970.Lucien Daiiveau, ij.c, 36303 A ssociale Deputy M in isler of .1 usliee.Chi-Ting Chen The Lieutenant-Governor in Council has lien pleased, by Order number 3257 of September % 1970, to effect the change of name of Clmi-Tiai Wai into that of Chi-Ting Chen and of his two (2) children Marge Wai and Edward Gcc-GingWd into that of Marge Chen and Edward (iee-(iiu Chen.Québec, September 10, 1970.Lucien Darveau, q.c, 30303 Associate Deputy Minister of .1 ttstice.Irving Martin Diamond The Lieutenant-Governor in Council has lieen pleased by Order number 3265 of September 2, 1970, to effect the change of name of Irvinj Martin Zucow into that of Irving Martin Diamond .Québec, September 10, 1970.Lucien Darveau, q.c 36303 Associate Deputy Minister of .lustier.Eugene Dollin The Lieutenant-Governor in Council has lien pleased by Order number 3260 of September 2, 1970, to effect the change of name of Eugrat Psiuk into that of Eugene Dollin.Québec, Scptemlier 10, 1970.Lucien Daiivkai ..pnsc entre la rivière St-Jean et les limites Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has l>ecn pleased to make, by Commissions under the Great Seal of the Province, the following appointments, to wit: Québec, March 25, 1970.Mr.Robert Daveluy of Montmagny, advocate and member of the Bar of Québec: Queen's Counsel learned in the law.Québec, August 19, 1970.Mr.Robert Pidgcon, advocate of Gaspé, county of Gaspé South: coroner for the judicial district of Gaspé, with jurisdiction particularly on this part of the electoral district of Gaspé South includes between St.John River and the 5322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 88 nord-est du district électoral de Bonavcnturc, à north-cast limits of the electoral district ol compter de son asscrmentation.Bonaventurc, from and after his swearing in Québec, le 16 septembre 1970.Québec, Septcmlicr 16, 1970.Le sous-procureur général adjoint, Lucien Daiiveau.i des syndicats professionnels, Statuts refondus 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchahu.36318-0 42-68 Syndicat National des Travailleurs de l'Aluminium de Bcauharnois inc.(C.S.N.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que lc 13 août 1970, il a autorisé le changement de nom de « L'Association Canadienne (les ouvriers dc l'Aluminium Local No.I », dont la constitution a été autorisée le 20 février 1951, avec siège social à Bcauharnois, en celui dc * Syndicat National des Travailleurs de l'Aluminium dc Bcauharnois inc.(C.S.N.) », ct ce, en vertu dc la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchaiiu.36319-0 617-51 Professional Syndicates Association des Camionneurs Artisans du Comté dc Laviolette (Professional Syndicales Acl) Notice is hereby given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Coope-ratives, on August 31, 1970, decreed that llie corporative existence of the \"Association des Camionneurs Artisans du Comté de l.nviolelle\", be terminated, the incorporation of which nt authorized on May 7, 1968, with the head office at Grand'Mère, judicial district of Saint-Maurice, and this, in accordance with section 25 of tbt Professional Syndicates Act, Revised Statute! of 1964, chapter 146.Ls-Philippe Bouciiaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalitts.36318 4248 Syndicat National des Travailleurs dc PAIuminium dc Bcauharnois inc.(C.S.N.) (Professional Syndicales Acl) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has.on August 13, 1970, authorized the changed name of \"L'Association Canadienne des ouvrier! de l'Aluminium I,oeal No.I\", the incorporatioi of which lias been authorized on February 20.1951, with head office in Bcauharnois.into that of \"Syndicat National des Travailleurs de l'Aluminium dc Bcauharnois inc.(C.S.N'.)\", and such, pursuant to the Professional Syndicates Ad Revised Statutes, 1964, chapter 146.Ls-Philippe Bouciiaiid, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and ( 'ooperalirts.36319 «517-51 Ministère de l'Éducation Department of Education Colombourg Il a plu au lieutenant-gouverneur par arrêté en conseil No 3277, du 2 septembre 1970, d'annexer le territoire actuel dc la municipalité scolaire de Colombourg, dans le comté d'Ahitihi-Oucst, à la municipalité scolaire dc Lac-Abitibi, dans le comté d'Abitibi-Ouest.Ce changement prend effet à compter dc la date du présent arrêté en conseil.Québec, le 9 septembre 1970.Le ministre de l'Éducation, Guy Saint-Pi eiire.3033 l-o 310-01 Saint-Biaise Il a plu au lieutenant-gouverneur par arrêté en conseil No 3276, en date du 2 septembre 1970, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Saint-Blaisc, dans le comté d'Abitibi-Est, à la municipalité scolaire de Barrante, dans le comté d'Abitibi-Est.Colombourg The Lieutenant-Governor has been pleased by Order in Council No.3277 of September 2.1970, to annex the actual territory of II»' school municipality of Colombourg, in the county of Abitibi West, to the school municipality of I-ar-Abitibi, in the county of Abitibi West.This change takes effect from and after tlie date of this Order in Council.Québec, Scptemlicr 9, 1970.Guy Saixt-I'ikiiiik.Minister of Education.36331 310MII Saint-Blaise The Lieutenant-Governor has been |dca*d by Order in Council No.3276 of September i.1970, to annex the actual territory of the school municipality of Saint-Blaise, in the county « Abitibi East, to the school municipality « Barraute, in the county of Abitibi Fast. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5323 Ce changement prend effet à compter dc la date du présent arrêté en conseil.Quélicc, le 9 septembre 1970.Le ministre de l'Education, Guy Saint-Pierre.30331.190-02 Saint-CIébphas Il u plu au lieutenant-gouverneur par arrêté ci conseil N 3277, en date du 2 septembre 1970, d'annexer le territoire actuel de la municipalité scolaire de Suint-Cléoplias, dans le comté dc Matapédia, à la municipalité scolaire dc Sayabec, dans le comté dc Matapédia.Ce changement prend effet à compter dc la date du présent arrêté en conseil.(jiiel.ee, le 9 septembre 1970.Le ministre de l'Education, Guy Saint-Pierre.36331-0 505-03 This change takes effect from and after the date of this Order in Council.Quebec, September 9,1970.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.36331 190-02 Sainl-Cléophas The Lieutenant-Governor has been pleased by Order in Council No.3277 of Scptemlwr 2, 1970, to annex the actual territory of the school municipality of Saint-Cléophas, in the county of Matapédia, to the school municipality of Suyabcc, in the county of Matapédia.This change takes effect from and after the date of this Order in Council.Québec, September 9, 1970.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.36331 505-03 I.es-Dcux-Rivcs II a pill au lieutenant-gouverneur par arrêté in conseil numéro 3277, en date du 2 septembre 1970, de fusionner le territoire actuel des muni-| ripalités scolaires de la cité dc Kénogami, dans le comté «le Jonquière; Saint-Ainbroisc ct Saint-.Icaii-N'.viingéliste, dans le comté dc Dubuc, et de l'ériger en une nouvelle municipalité scolaire | sous le nom de Les-Deux-Rives, dans les comtés du Dubuc et -lonquicrc.\\fi nombre des commissaires d'écoles pour I celte nouvelle municipalité est fixé à sept (7).Son territoire est divisé en sept quartiers, I numérotés, représentés et délimités comme suit: Le quartier numéro 1, représenté par un com-| niissairo, comprend le territoire décrit dans le document ci-annexé; Le quartier numéro 2, représenté par un commis-jsaire, comprend le territoire décrit dans le docu-[ ment ci-annexé; Le quartier numéro 3, représenté par un commis-Isaire, comprend le territoire décrit dans le docu-I ment ci-annexé; Le quartier numéro représenté par un com-imissaire comprend le territoire «lécrit dans le | docunu-iit ci-annexé; Le quartier numéro 5, représenté par un com-Imksaire, comprend le territoire actuel de la mu-|rucipalité Saint-Ambroise paroisse; /.r quartier numéro 6, représenté par un commis-isaire comprend le territoire actuel de la munici-[paliléde Saint-Ambroise village; Lt quartier numéro 7, représenté par un com-imissaire.comprend le territoire actuel de la municipalité scolaire dc Saint-Jcan-l'Èvangéliste.\u2022«iicboc, le 9 septembre 1970.Lc ministre de l'Education, Guy Saint-Pierre.UVRE DES DÉLIBÉRATIONS L* Commission des Écoles de la cite de Kénogamie |our l'achat dc S123.000 d'obligations du Village dc Ripon, comté dc Papineau, datées du 1er novembre 1970 ct remboursables par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J^%, ni supérieur à 9}^%> payable senti-annuellement les 1er mai ct 1er novembre dc chaque anne'-c.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans lc présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1970.Tableau d'amortissement \u2014 3123,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1971.$ 1,000 1er novembre 1972.1,000 1er novembre 1973.1,000 1er novembre 1974.1,000 1er novembre 1975.1,000 1er novembre 1976.1,500 1er novembre 1977.1,500 1er novembre 1978.1,500 1er novembre 1979.1,500 1er novembre 1980 .2,000 1er novembre 1981.2,000 1er novembre 1982 .2,000 1er novembre 1983 .2,500 1er novembre 1984 .2,500 1er novembre 1985 .3,000 1er novembre 1986 .3,000 1er novembre 1987.3,500 1er novembre 1988 .4,000 1er novembre 1989 .4,500 1er novembre 1990.83,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.Village of Ripon County of Papineau Public notice is hereby given thai sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Rene Lafontainc, Secretary-Treasurer.Tom Hall, Post Office Box 100, Village of Hipon, county of Papineau, P.Q., until 8:00 o'clock-, p.m., on Tuesday, October 6, 1970, for the purchase of an issue of S123,000 of bonds for the Village of Ripon, county of Pupincau, dated November I, 1970 and redeemable serially from November I, 1971 to November 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8J nor more than 9J-^%, payable semi-annually on May 1st ami November 1st of each year.The rale ol interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued ut each différent rale must rover or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall lie calculated as from November 1, 1970.Table of redemption \u2014 SI23,000 \u2014 JO yean Year Capital November 1, 1971.S 1,000 November 1, 1972.1,000 November 1, 1973.1.000 November 1, 1974.1,000 November 1, 1975.1,000 November 1, 1976.1,600 November 1, 1977.1,500 November 1, 1978.1,500 November 1, 1979.1,500 November 1, 1980.2.001) November 1, 1981.2.0110 November 1, 1982.2,000 November 1, 1983.2,500 November 1, 1984 .2,500 November 1, 1985.3,000 November 1, 1986.3,000 November 1, 1987.3,500 November 1, 1988.'.(MHJ November 1, 1989.-1.500 November 1, 1990.83.000 Moreover, only the following terms and con* tions shall be considered: 1.Five-year, 10-yenr or 15-year short-tern serial bonds. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5329 2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.i° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.0° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans jiour une partie ct l'autre partie à ternie fixe 20 ans.Toutefois, dans lc cas des paragraphes 4 , 5 et 0°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être ]>our un montant inférieur à SI 1.51)0 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances dc la partie renou-I velalilc ci-après mentionnée.Également, les I obligations émises à courte échéance 5 ans ou 110 uns, ne devront comporter que des amortisse-I ments annuels entiers, ct en commençant par I les dernières années d'échéances excluant la I partie qui sera à terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être I transmises que pour un seul des modes d'émission Ici-haut et ne devront comporter qu'un seul des I termes sauf dans les cas des exceptions notées.I L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er novembre 1990 au montant Idc (83,000 comprend un solde de §78,500 renou-I vcnnhlc pour une période additionnelle dc 10 ans, let échéant comme suit: Année Capital 1er novembre 1991.$5,000 I 1er novembre 1992 .5,500 j 1er novembre 1993 .6,000 ' 1er novembre 1994 .6,500 ! 1er novembre 1995 .7,500 1er novembre 1996 .8,000 I 1er novembre 1997 .8,500 J 1er novembre 1998.9,500 I 1er novembre 1999.10,500 I 1er novembre 2000.11,500 |l L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, ¦capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque ¦visé, payable au pair à Saint-André-Avelin.I I* capital et les intérêts sont payables a toutes ¦«succursales dans la province de Québec de ¦la banque dont lc nom est mentionné dans la ¦procedure d'emprunt.I Lesditcs obligations ne seront pas rachetables ¦W anticipation si elles sont émises par séries ¦*« series et terme fixe 20 ans, pour un montant WW ou moindre de 883,000.Toutefois, si elles ¦W émises en partie à terme fixe 20 ans pour mi montant supérieur à 883,000 les obligations mm omises seront rachetables par anticipation, »u l>air, le 1er novembre de chaque année pour ¦f montant annuel requis pour les fins de l'amor-¦jMscmcnt de l'émission, conformément aux ¦aauieaux d échéances de l'émission apparaissant ¦ans le present avis.ft Uaque soumission devra être accompagnée leW6?\"0 \"S*1** égal à l% du montant dc lomnr et devra spécifier si le prix offert mZl i r U \"c comPrend pas les intérêts courus | 'es obligations au moment de leur livraison.2.Ten-year serial bonds with the balance as 20-year fixcd-term bonds.(3) Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with the balance partly as 10-year short-term bonds and partly as 20-year fixed-term bonds.5.Ten-year serial bonds with the balance partly as 5-ycar short-term and partly as 20-ycar fixed-term bonds.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-ycar fixed-term bonds shall be for an amount of not less than $11,500, and, if higher than this latter amount, the said part shall comprise only one of more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting with the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-year or 10-ycar short-term bonds shall included only complete annual amortizations, starting with the last years of maturities, excluding the 20-ycar fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The November 1, 1990 maturity in the amount of 883,000 includes a balance of $78,500 renewable for an additional 10-year period, and maturing as follows: Year Capital November 1, 1991.$ 5,000 November 1, 1992 .5,500 November 1, 1993.6,000 November 1, 1994.6,500 November 1, 1995.7,500 November 1, 1996 .8,000 November 1, 1997 .8,500 November 1, 1998.9,500 November 1, 1999.10,500 November 1, 2000.11,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Saint-Andrc-Avclin.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than or less than $83,000.However, should they be issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $83,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on November 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender. 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 88 Lcsditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 67 \u2014 $123,000 \u2014 aqueduc, égouts, etc.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance 'du conseil qui sera tenue, mardi, le 6 octobre 1970, à 8 heures du soir, Hôtel dc Ville, Case postale 100, Village dc Ripon, comté dc Papineau, P.Q.Lc conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ripon (Comté de Papineau), ce 9 septembre 1970.Lc secrétaire-trésorier, Rrcxfc Lafontaine.Hôtel dc Ville, Case postale 100, Village dc Ripon, Comté de Papineau, P.Q.Téléphone: 983-6685, code 819.36295-0 The said bonds will be issued pursuant to U* following by-laws: 67 \u2014 $123,000 \u2014 aquèdutt sewers, etc.The tenders will be opened and considered al a meeting of the council to be held on Tuesday October 6, 1970, at 8:00 o'clock, p.m., at lb Town Hall, Post Office Box 100, Milage Ripon, county of Papineau, P.Q.The council does not bind itself to accept llie highest or any of the tenders.Ripon (County of Papineau), September 9 1970.René Lafoxtaixe, Secretary-Treasurer.Town Hall, Post Office Box 100, Village of Ripon, County of Papineau.P.Q.Telephone : 983-6685, code 819.36255 Village dc Crabtrec Comté dc Jolicttc Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct portant l'inscription \u2022 Soumissions pour obligations » seront reçues pnr le soussigné J.D.Payette, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heures du soir, bureau de la corporation, 199, 2c Avenue, Crabtrce, comté de Jolicttc, P.Q., ct par après jusqu'à 8 heures du soir, salle municipale, 12e Rile, Crabtrec, comté de Jolicttc, P.Q., mercredi, lc 7 octobre 1970, pour l'achat dc $3S3,0O0 d'obligations du village dc Crabtrce, comté dc Joliette, P.Q., datées du 1er novembre 1970 et remboursables par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à &14%> ni supérieur à 9}^%.payable scini-annuellcmcnt les 1er mai ct 1er novembre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement elans lc présent avis.Règlement numéro 69 \u2014 $383,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1970.Tableau d'amortissement \u2014 S3S3,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1971.$19,000 1er novembre 1972.19,000 1er novembre 1973.19,000 1er novembre 1974.18,000 1er novembre 1975.17,000 1er novembre 1976.16,000 1er novembre 1977.14,000 1er novembre 1978.14,000 1er novembre 1979.14,000 1er novembre 1980.14,000 1er novembre 1981.14,000 1er novembre 1982.15,000 1er novembre 1983.17,000 1er novembre 1984.19,000 1er novembre 1985 .20,000 1er novembre 1986 .22,000 1er novembre 1987.24,000 1er novembre 1988 .27,000 1er novembre 1989 .29,000 1er novembre 1990 .32,000 En plus, les modalités suivantes seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.Village of Crabtrec County of Jolicttc Public notice is hereby given that seaW tenders bearing the inscription \"Tenders lot bonds\" will be received by the undersigned JD.Payette, Secretary-Treasurer, until 7:30o'clod p.m., at the Office of the Corporation.199,2nd Avenue, Crabtrec, county of Jolicttc.P.Q., i after until 8:00 o'clock p.m., at the .Munieipd Hall, 12th Street, Crabtrce, county of Jolictlf, P.Q., on Wednesday, October 7, 1970, for Ik purchase of an issue of $383,000 of bonds 1er the village of Crabtrec, county of Jolicttc, l'.Q, dated November 1, 1970 and redeemable serial); from November 1, 1971 to November 1, inclusively, with interest nt a rule not less tkn 83-3%.nor more than 9J^%, payable semiannually on May 1st and November lstofcid year.The rate of interest muy be l hissante for the whole issue; however, if more than one nil is used, the amount issued at each different ilk must cover one or several whole annual amodiations, as shown on the table of redemption a this notice.By-law number 69 \u2014 $383,000 aquednd, sewers, roads.For adjudication only, interest shall I* can* latcd as from November 1, 1970.Table of redemption \u2014 8333,000 \u2014 20 yam Year Capital November 1, 1971.$19,000 November 1, 1972.19,000 November 1,1973.19.000 November 1, 1974.18,000 November 1, 1975.1Ï.O00 November 1,1976.16,000 November 1, 1977.W.O00 November 1,1978.14,009 November 1, 1979.I4.0J5 November 1, 1980.14,000 November 1, 1981.I*»0M November 1,1982.15,000 November 1, 1983.17.0W November 1, 1984.19,000 November 1,1985.'-'0,000 November 1, 1986.-'2,000 November 1, 1987.24,000 November 1, 1988.27,000 November 1, 1989.29,000 November 1, 1990.;'2-000 Moreover, the following methods of issue skd be considered: 1.Five-year, 10-year or 15-ycar short-m» serial bonds. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.10S, No.88 5331 2° Obligations Échéant en series 10 ans avec le solde A lerme fixe 20 ans.:i° Obligations échéant en séries 10 ans avec Icsoklc n courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde â < ourle échéance 10 ans pour une partie cl l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'unir< partie à terme fixe 20 ans.Ii° Obligutions échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie ù terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° el 06, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 832,000, el si supérieur à ce dernier montant, celte parlic devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières innées d'échéances.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront ciini|)ortcr que des amortissements annuels entiers, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui .sera il ternie fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes «rémission eidiaul ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.I.'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair i\\ Jolicttc Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province «le Québec «le la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries et terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de 832,000.Toutefois, si elles sont émises on partie ù terme fixe 20 ans |k>ur un montant supérieur à $32,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 1er novembre dc chaque année pour le montant, annuel requis pour les fins de l'amortissement de rémission, conformément au tableau déchéances de l'émission apparaissant dans le prisent avis.Chaque soumission devra être accompagnée dun chèque accepté égal à 1% du montant «le I emprunt et devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Us soumissions seront ouvertes ct considérées j\" une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 7 octobre 1070, à 8 heures du soir, salle Inuni-JJfale, 12e Hue, Crabtrce, comté «le Jolicttc, u conseil se réserve lc droit de n'accepter ni ¦ plus haute ni aucune des soumissions.1970ablrC* ('Comté de Joliclle).11 septembre Le secrétaire-trésorier, J.D.Payette.Bureau de la corporation, 199, 2e Avenue, trab reç (Comté de Joliette), P.Q.telephone: 754-2402, code 514.36333-0 2.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixc«l-tcrm bonds.3.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with the balance partly as 10-year short-term and partly as 20-year fixed-term bonds.5.Ten-year serial bonds with the balance partly as 5-year short-term and partly as 20-year fixed-term bonds.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-year fixed-term bonds shall be for an amount of not less than $32,000, and if higher than this latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the table of maturities appearing in this notice, and starting with the last years of maturities.Also, the 5-year or 10-year short-term bonds shall comprise only complete annual amortizations, and starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall lie made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by ccrtific«l cheque payable at par at Jolicttc.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procc«lure.The said bonds will not lie redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-ycar fixed-term bonds for an amount, equal to or less than $32,000.However, should they be issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $32,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at I>ar, on November 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, October 7, 1970, at 8:00 o'clock p.m., at the Municipal Hall, 12th Street, Crabtrce, county of Joliette, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Crabtrec (County of Joliette), September 11, 1970.J.D.Payette, Secretary-Treasurer.Office of the Corporation, 199, 2nd Avenue, Crabtree (County of Joliette), P.Q.Telephone: 754-2402, code 514.36333 5332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n\" 38 La Commission scolaire régionale Honoré-Mercier Avis de correction Veuillez prendre note que dans l'avis de demande de soumissions pour l'achat dc 81,500,000 d'obligations «le la commission scolaire régionale Honoré-Mercier, qui a paru dans la Gazette officielle du Québec du 12 septembre 1970, à la page 5189, que les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue le mardi, 29 septembre 1970, à 8 heures 30 du soir (au lieu de S heures tel que mentionné).Tous les autres détails contenus tlans l'avis «lc demande dc soumissions indiqué ci-haut demeurent inchangés.St-Jcan, ce 14 septembre 1970.Le secrétaire-trésorier, Guy Durifc.69, Boulevard St-Joseph, St-Jean, (St-Jcan), P.Q.36348-0 Regional School Commission Honoré-Mercier Notice of correction Kindly note that in the notice of call for lenders for the purchase of an issue of $1,500,000 ol bonds of the Regional School ('¦ inmission Honoré-Mercier, published in the Québec Officia Gazette of September 12th, 1970, on page 5189 that the tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners lo be held Tuesday, September 29th, 1970.at 8:30 o'clock p.m.(instead of 8:00 o'clock p.m.mentioned).All the other details containeil in I he above mentioned notice of call for tenders remain unchanged.St-Jcan, September 14, 1970.Guy Di nfc, Secretary-Treasurer.69 St-Joseph Boulevurd, St-Jcan, (St-Jean), P.Q.3034S-0 Côte Saint-Luc Comté D'Arey McGee Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné A.E.Kimnicl, greliier, Hôtel de ville, 5490, Westminster, Côte Saint-Luc, Montréal 29, Québec, jusqu'à 19 heures 30, lundi, lc 5 octobre 1970, pour l'achat de 8995,000 d'obligations de Côte Saint-Luc, comté de D'Arcy McGee, «latées du 1er novembre 1970 ct remlwursablcs par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8)4%.ni supérieur ù 9J4%, payable semi-annucllemcnt les 1er mai ct 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé-, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement du présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1970.Tableau d'amortissement \u2014 3005,000 \u2014 20 ans Année Capital lernovember 1971.$ 22,000 1er novembre 1972.25,000 1er novembre 1973.26,000 1er novembre 1974.28,000 1er novembre 1975.31,000 1er novembre 1976.32,000 1er novembre 1977.36,000 1er novembre 1978.38,000 1er novembre 1979.41,000 1er novembre 1980.44,000 1er novembre 1981.38,000 1er novembre 1982.42,000 1er novembre 1983.44,000 1er novembre 1984.49,000 1er novembre 1985.53,000 1er novembre 1986.57,000 1er novembre 1987.61,000 1er novembre 1988.67,000 1er novembre 1989.72,000 1er novembre 1990.189,000 Dc plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, ou 10 ans ou 15 ans.Côte Saint-Luc County of D'Arcy McGcc Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned A.E, Kinunel City Clerk, City Hall, 5490 Westminster.Cote Saint-Luc, Montreal 29, Québec, until 7:30 o'clock, p.m., on Monday, October 5, 1970, for the purchase of au issue of $995,000 bonds ol Côte Saint-Luc, county of D'Arcy Met ice, dated November 1, 1970 and redeemable serially from November 1, 1971 to November 1.1990 inclui vely, with interest at a rate not less than 8}$J.nor more than 9]/>%, payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.Tlie rate of interest may be the same for llie whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cow one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption is this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from November 1,1970.Table of redemption \u2014 $005,000 -'0 yean Year Capital November 1, 1971.S 22,000 November 1, 1972 .25,000 November 1, 1973.20.000 November 1, 1974.-.XO0O November 1, 1975.31.000 November 1, 1976.32.000 November 1, 1977.30,000 November 1, 1978.38,000 November 1, 1979.-1 ! .(UK) November 1, 1980.'AM November 1, 1981.^.\"00 November 1, 1982.42,000 November 1, 1983.¦'1,000 November 1, 1984.49,000 November 1, 1985 .53,000 November 1, 1986.57,000 November 1, 1987.01,000 November 1, 1988.«7,000 November 1, 1989.72,000 November 1, 1990.Is'-'\"00 Moreover, only the following methods of is* shall be considered : 1.Five-year, 10-ycar or 16-year -bort-tenn serial bonds. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5333 2° Obligations échéant en scries 10 ans avec le soldes terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde ù courte échéance 5 ans.|° Obligations échéant en séries 10 ans avec |,.solde à courte échéance 10 ans pour une partie et l'autre |Hirtic ù tenue fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec I,, soldi- à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.O3 Obligations échéant en séries avec court.-édiéaiicc 5 ans pour une partie ct l'autre partie à ternie fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4, 5 et I).|çs obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas clic pour un montant inférieur à $9,000.cl -i supérieur à ce dernier montant, cette partie ne devra comprendre qu'un ou des amortissement\" annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéance apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéance de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à comte échéance 5 ans ou 10 ans ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéance, excluant la partie qui sera ù terme fixe 211 ans.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut cl m- devront comporter qu'un seul des termes sauf duns le cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er novembre 1990 pour une somme de S1S9.000 comprend un solde d.-$113,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans et échéant comme suit: 2.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.3.Ten-year serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with the balance partly as 10-ycar short-term and partly as 20-ycar fixed-term bonds.5.Tcn-ycar serial bonds with the balance partly as 5-year short-term and partly as 20-year fixed-term bonds.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-ycar fixed-term bonds shall be for an amount of not less than $9,000, and if higher than this latter amount, the said part must comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities of the issue appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-year or 10-ycar short-term bonds shall comprise only entire annual amortizations, and starting by the last years of the maturities excluding the 20-ycar fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The November 1, 1990 maturity in the amount of 8189,000 include a balance of $113,000 renewable for an additional 20-year period, and maturing as follows: Année Capital 1er novembre 1991.$2,000 1er novembre 1992.3,000 1er novembre 1993.3,000 1er novembre 1994.4,000 1er novembre 1995.4,000 1er novembre 1996.4,000 1er novembre 1997.4,000 br novembre 1998.4,000 br novembre 1999.5,000 1er novembre 2000.5,000 1er novembre 2001.6,000 1er novembre 2002.6,000 1er novembre 2003.7,000 1er novembre 2004.7,000 1er novembre 2005.7,000 br novembre 2006.8,000 1er novembre 2007.8,000 br novembre 2008.8,000 br novembre 2009.9,000 1er novembre 2010.9,000 L adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Montréal.Le capital et les intérêts sont payables à toutes \u2022es succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procedure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal ne ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsditcs obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou m series et terme fixe 20 ans, pour un montant ega a ou moindre dc 8189,000.Toutefois, si elles »nt émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $189,000, les obligations «a émises seront rachetables par anticipation, a\" pair, le 1er novembre de chaque année pour Year Capital November 1, 1991.$2,000 November 1,1992 .3,000 November 1, 1993 .3,000 November 1, 1994 .4,000 November 1, 1995 .4,000 November 1, 1996 .4,000 November 1, 1997 .4,000 November 1, 1998 .4,000 November 1, 1999 .5,000 November 1, 2000 .5,000 November 1,2001.6,000 November 1,2002 .6,000 November 1,2003 .7,000 November 1,2004 .7,000 November 1,2005 .7,000 November 1, 2006 .8,000 November 1, 2007 .8,000 November 1, 2008 .8,000 November 1, 2009 .9,000 November 1, 2010.:.9,000 The successful'tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Montreal.Capital and interest arc payable at all branches in the province of Quélicc of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued serially or serially and as 20-ycar fixed-term bonds for an amount equal to or less than $189,000.However, if they are issued partly for 20-year fixed-term for an amount higher than $189,000, the bonds so issued shall be redeemable by anticipation, at par, on November 1st of each year for the annual amount required 5334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 38 la somme annuelle requise pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément aux tableaux d'échéance de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% de la somme dc l'emprunt ct devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 907 \u2014 $27,000 \u2014 travaux de voirie; 908 \u2014 $30,000 \u2014 travaux de voirie; 920 \u2014 823,000 \u2014 services récréatifs ct communautaires; 998 \u2014 $66,000 \u2014 éclairage; 999 \u2014 84,000 \u2014 éclairage; 1033 \u2014 84,000 \u2014 éclairage; 1045 \u2014 $2,000 \u2014 travaux de voirie; 1084 \u2014 823,000 \u2014 canalisations, égouts; \u2014 1089 \u2014 820,000 \u2014 achat dc livres; 1092 \u2014 $20,000 \u2014 travaux de voirie, etc.; 1096 \u2014 $11,500 \u2014 éclairage, etc.; 1104 \u2014 $13,000 \u2014 éclairage, etc.; 1111 \u2014 $130,000 \u2014 canalisations, égouts; 1116 \u2014 815,000 \u2014 canalisations, égouts; 1121 \u2014 818,000 \u2014 travaux de voirie; 1124 \u2014 $120,000 \u2014 travaux de voirie; 1130 \u2014 $11,500 \u2014 frais dc refinancement; 1131 \u2014 S3.000 \u2014 éclairage; 1133 \u2014 83,700 \u2014 éclairage; 1135 \u2014 $23,000 \u2014 achat dc livres; 1139 \u2014 87,800 \u2014 travaux de voirie; 1006 \u2014 8146,500 \u2014 travaux dc voirie; 1145 \u2014 $256,500 \u2014 construction ct terrains; 1144 \u2014 $16,500 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 5 octobre 1970, à 19 heures 30, à l'Hôtel de ville, 5490, Westminster, Côte Saint-Luc, Montréal 29, Québec.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Côte Saint-Luc (Comté dc D'Arcy McCiec), lc 10 septembre 1970.Le greffier, A.E.KiM.Mi-.i.Hôtel de ville 5490, Westminster Côte Saint-Luc (Comté tie D'Arcy McGee), Montréal 29, Québec.Téléphone: 489-9771, code 514.36334 Ville de Terrebonne Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean-Jacques I.auzon, secrétaire-trésorier.Hôtel dc ville, 775, rue St-Jean-Bap-tiste, Case postale 60, Terrebonne, comté de Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, mardi, le 6 octobre 1970, pour l'achat de $362,500 d'obligations de la ville de Terrebonne, comté de.Terrebonne, datées du 1er novembre 1970 et remboursables par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%%, ni supérieur à 9^%, payable semi-annucllement les 1er mai et 1er novembre de chaque année.I,e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1970.Tableau d'amortissement \u2014 8862,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er novembre 1971.$ 7,500 1er novembre 1972 .8,000 to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice Eeach tender must be accompanied by u ccr(j_ fied cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest, accrue! on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender; The said bonds will be issued pursuant to tlie following by-laws: 907 \u2014 $27,000 \u2014 road works' 908 \u2014 $30,000 \u2014 road works; 920\u2014 $23,000-rccreational and communitv services: 99$ _ $66,000 \u2014 lighting: 999 \u2014' $4,000 \u2014 lishtins-1033 \u2014 $4,000 \u2014 lighting; 1045 \u2014 $2,000 -road works; 1084 \u2014 823,000 \u2014 waterworks sewers; 1089 \u2014 $20,000 \u2014 purchase of book?1092 \u2014 $20,000 \u2014 road works etc.; 1096 -$11,500 \u2014 lighting, etc.; 1104 \u2014 $13,000 -lighting, etc.; 1111 \u2014 $130,000 \u2014 waterworks sewers; 1116 \u2014 $15,000 \u2014 waterworks, sewers-1121 \u2014 818,000 \u2014 road works; 1124 \u2014 8120,000 \u2014 road works; 1130 \u2014 $11,500 \u2014 rcfinancnu cost; 1131 \u2014 83,000 \u2014 lighting; 1133 \u2014 83,700-lighting; 1135 \u2014 $23,000 \u2014 purchase of boob' 1139 \u2014 87,800 \u2014 road works; 10D6 \u2014 S146,500 -road works; 1145 \u2014 $256,500 \u2014 building ami lands; 1144 \u2014 $16,500 \u2014 refinancing cost.The tenders will be opened and considered al a meeting of the council to be held on Monday, October 5, 1970, at 7:30 o'clock, p.m., nt the City Hall, 5490 Westminster, Côte Saint-Luc, Montreal 29, Québec.The council does not bind itself to aeeepl the highest or any of the tenders.Côte Saint-Luc (County of D'Arcy McGee), this September 10, 1970.A.E.Ki.M.uia, Cil u Clerk.City Hall, 5490 Westminster, Côte Saint-Luc (County of D'Arcy McGce, Montreal 29, Québec.Telephone: 489-9771, code 514 .30334m City of Terrebonne County of Terrebonne Public notice is hereby given that scaled tenders bearing the inscription '\"renders for Bonds\" will be received by the undersigned Jean-Jacques Lauzon, Scerctary-Trcasim-r.City Hall, 775 St-Jean-Baptistc Street, l'ost Ollice Box 60, Terrebonne, county of Tent-bonne, l'.Q., until 8:30 o'clock, p.m., on Tuesday.October 6, 1970, for the purchase of an issue of $302,500 ol bonds for the city of Terrebonne, county ol Terrebonne, dated November 1, 197(1 and redeemable serially from November 1.1971 to November 1, 1990 inclusively, with interest at a rate not less than 8^%, nor more than 9)4%.payable semi-annually on May 1st and November 1st of each year.The rate of interest may lie the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several w'liole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from November 1, 1970.Table of redemption \u2014 $362,600 \u2014 20 years Year Capital November 1, 1971.$ '.500 November 1, 1972.8,000 QUE-BEC OFFICIAL GAZETTE, September 10, 1070, Vol.102, No.88 5335 1er novembre 1973 .8 9,000 I,., novembre 1974.10,000 le, novembre 1975.11,000 1er novembre 1976.11,000 1er novembre 1977.12,000 1er novembre 1978.13,000 1er novembre 1979.14,000 1er novembre 1980.15,000 1er novembre 1981.17,000 1er novembre 1982.17,000 1er novembre 1983.18,000 1er novembre 1984 .20,000 1er novembre 1985.22,000 1er novembre 1986 .24,000 1er novembre 1987 .25,000 1er novembre 1988 .27,000 1er novembre 1989.30,000 1er novembre 1990 .52,000 En plu\", les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 uns.ou 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à térmC fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec 1 le solde ù courte échéance 10 ans pour une partie | et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie | ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.G° Obligations échéant en séries avec courte j échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie I à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° [et 6°, les obligations échéant à terme fixe 20 ans lie devront pas être |xnir un montant inférieur à I $20,000, et si supérieur à ce dernier montant, Icctlc partie devra comprendre qu'un ou des (amortissements annuels entiers, en tenant compte pics tableaux d'échéances apparaissant dans le Iprésent avis, et en commençant par les dernières Iinnées d'échéances de la partie renouvelable Ici-après mentionnée.Également, les obligations lemises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne ldevronl comporter (pie des amortissements an-Imicls entiers, et en commençant par les dernières notes d'échéances excluant la partie qui sera à |terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être ¦transmises que pour un seul des modes d'émis-won a-haut et ne devront comporter qu'un seul Ides ternies sauf dans les cas des exceptions notées, f* adjudication sera faite conformément à la loi.¦i !*M«K!C du 1er novembre 1990 au montant Ile 152,000 comprend un solde de $20,000 renou-Pelahlç pour une période additionnelle de 20 ans, ft échéant comme suit: Année Capital 1er novembre 1991.$1,000 1er novembre 1992.1,000 1er novembre 1993.1,000 1er novembre 1994.1,000 1er novembre 1995.1,000 1er novembre 1996.1,000 1er no-embre 1997.1,000 1er novembre 1998.1,000 1er novembre 1999.1,000 1er novembre 2000.l|o00 [er novembre 2001.' l'oOO er novembre 2002.1000 er novembre 2003.l'oOO '\"novembre2004.1000 November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, November 1, 1973.$ 9,000 1974.10,000 1975.11,000 1976.11,000 1977.12,000 1978.13,000 1979.14,000 1980.15,000 1981.17,000 1982.17,000 1983.18,000 1984.20,000 1985'.22,000 1986 .24,000 1987 .25,000 1988 .27,000 1989 .30,000 1990 .52,000 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered : 1.Five-year, 10-ycar or 15-year short-term serial bonds.2.Ten-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.3.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds.4.Tcn-ycar serial bonds with the balance partly as 10-ycar short-term bonds and partly as 20-ycar fixed-term bonds.5.Ten-year serial bonds with the.balance partly as 5-year short-term and partly as 20-ycar fixed-term bonds.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-ycar fixed-term bonds shall be for an amount of not less than 820,000, and, if higher than the latter amount, the said part shall comprise only one or more entire annual amortizations, bearing in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-year or 10-year short-term bonds shall include only complete annual amortizations, starting with the last years of maturities, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The November 1, 1990 maturity in the amount of $52,000 includes a balance of $20,000, renewable for an additional 20-ycar period, and maturing as follows: Year Capital November 1, 1991.$1,000 November 1, 1992.1,000 November 1, 1993.1,000 November 1, 1994.1,000 November 1, 1995.1,000 November 1, 1996.1,000 November 1, 1997.1,000 November 1, 1998.1,000 November 1, 1999.1,000 November 1, 2000.1,000 November 1, 2001.1,000 November 1, 2002.1,000 November 1, 2003.1,000 November 1, 2004.1,000 5336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n 33 1er novembre 2005.SI ,000 1er novembre 2006.1,000 1er novembre 2007.1,000 1er novembre 2008.1,000 1er novembre 2009.1,000 1er novembre 2010.1,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre de 852,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $52,000, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er novembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission, conformément aux tableaux d'échéances dc l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt ct devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 820 \u2014 $185,000 \u2014 voirie; 832 \u2014 886,500 \u2014 aqueduc et égout-s; 833 \u2014 836,500 \u2014 voirie; 848 \u2014 S19.5O0 \u2014 aqueduc et égouts; 871 \u2014 $35,000 \u2014 bâtisses ct terrains.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue murdi, lc 6 octobre 1970, à 8.30 heures du soir, Hôtel de ville, 775, rue St-Jean-Baptistc, ('use postale 60, Terrebonne, comté dc Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Terrebonne (Comté dc Terrebonne), ce 10 septembre 1970.Ije secrétaire-trésorier, Jean-Jacques Lauzox.Hôtel dc ville, 775, rue St-Jean-Baptistc, Case postale 60, Tcrrelwnne (Terrebonne), P.Q.Téléphone : 666-4123, code 514.36335-o November 1, 2005.81.000 November 1, 2006.: in m November 1, 2007.pinm November 1, 2008.|,Q00 November 1, 2009.1.000 November 1, 2010.i.uiin The successful tenderer agrees to \\r.,y for (ht bonds, capital and accrued interest, if any, I»-certified cheque payable at par at Ti rrcbonne.Capita] and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bunk mentioned in the loan procedure as well as at the I lead office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not.be redeemable hv anticipation if they arc issued serially or serially and as 20-ycar fixed-term bonds for an amount equal to or less than $52,000.However, if they are issued partly as 20-year fixed-term bond» for an amount greater than 852.1)00.the honih so issued will be redeemable by anticipation, al par, on November 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of tlie issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery i< included or not in the price of the lender.The said bonds will be issued pursuant to tlie following by-laws: 820 \u2014 8185,000 reads; 832 \u2014 886,500 \u2014 aqueduct and sewers: S33 -836,500 \u2014 roads: 848 \u2014 810.5(10 aqueduct and sewers; 871 \u2014 835,000 \u2014 buildings and hunk The tenders will lie opened and considered al a meeting of the council to Ik- held on Tuesday, October 6, 1970, at S:30 o'clock, p.m., at Hit City Hull, 775 St-Jcan-Baptistc Street, FM Office Box 60, Terrebonne, county of Tern-bonne, P.Q.The council does not bind itself to accept 111 highest or any of the tenders.Terrebonne (Countv of Terrebonne >.Septra lier 10, 1970.Jean-Jacques Lauzox, Secretary- Treasurer: City Hall.775 St-.lcan-Baptiste Street, Post Office Box 60, Terrebonne (Terrebonne), P.Q.Telephone: 666-4123.cod.- 511.Ville dc Hauterive Comté de Saguenay Avis public est par les présentes donné que «les soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par lc soussigné Gilbert Moffatt, secréluire-trésoricr, jusqu'à 5 heures dc l'après-midi, Hôtel de Ville, 625, boul.Laflèchc, Hauterive, comté «le Saguenay, P.Q., et par après jusqu'à 7.30 'heures «lu soir, Salle «les Conférences du conseil, 625, boul.Laflèchc, Hauterive, comté dc Saguenay, P.Q., lundi, le 5 octobre 1970, pour l'achat de 8286,000 d'obligations de la ville de Hauterive, comté de Saguenay, datées du 15 octobre 1970 ct remboursables par séries du 15 octobre 1971 au 15 octobre 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8^%, ni supérieur à 9J^%, payable semi-annuel lemcnt les 15 avril et 15 octobre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute Town of Hauterive County of Saguenay Public notice is hereby given that scaled tenders bearing the inscription \"Tenders W bonds\" will be received by th< undeis** Gilbert Moffatt, Secretary-Treasurer, until M o'clock p.m., at the Town Hall, 025 \\*m Boulevard, Hauterive, county of SajpHMj Québec, and thereafter until 7:30 oçtockp» at the Council's Conference Hall, 620 UKe* Boulevard, Hauterive, county of SupM* Québec, Monday, October 5.1970, for the p* chase of a bond issue of S2.SO.000.bonds o » town of Hauterive, county of Saguenay, arm October 15, 1970 and redeemable serially October 15, 1971 to October 15, 1990 meg* with interest at a rate not less than Vm-more than 9^%.payable soin.-winimBJj April 15th ami October lôth each year.J« ° of interest may be the same for II\"' whole i> It QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5337 rémission: cependant, si plus d'un taux est nlilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le present avis.Règlements Nos: 187 \u2014 $28,400 \u2014 voirie; ISS - SUi.000 \u2014 voirie; 189 \u2014 $78,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 190 \u2014 S7.000 \u2014 achat d'une pompe; 206 \u2014 $152,000 \u2014 aqueduc, fgouts; 213 \u2014 S2.000 \u2014 voirie; 214 \u2014 $2,600 \u2014 voirie.Pour adjudication seulement, 1 intérêt sera calculé ù compter du 15 octobre 1970.Tableau d'amortissement \u2014 S286,000 \u2014 20 ans Aimée Capital 15 octobre 1971.S 6,000 15 octobre 1972.6,000 15 octobre 1973 .7,000 15 octobre 1974 .8,000 15 octobre 1975 .8,000 15 octobre 1976.9,000 15 octobre 1977.10,000 15 octobre 1978.10,000 15 octobre 1979.11,000 15 octobre 1980.12,000 15 octobre 1981.13,000 15 octobre 1982.15,000 15 octobre 1983.16,000 15 octobre 1984.17,000 15 octobre 1985.19,000 15 octobre 1986.20,000 15 octobre 1987 .21,000 15 octobre 19S8 .24,000 15 octobre 1989.26,000 15 octobre 1990 .28,000 En plus, les modalités suivantes seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans, our 10 ans ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.G Obligations échéant en séries avec courte échéance ô ans pour une partie et l'autre partie à tenue fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas des paragraphes 4°, 5° et G , les obligations échéant à terme fixe 20 ans ;e«ôeVK>D' 'm?'lre Pour un montant inférieur I 828,000 et si supérieur à ce dernier montant, rette partie ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte «u tableau d'échéances apparaissant dans le present avis, cl en commençant par les dernières années d'échéances.Également, les obligations ''mises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières aimées d'échéances excluant la partie qui *ra a terme fixe 20 ans.Cependant, les soumissions ne devront être ifansmises que pour un seul des modes d'émission çi-haut et ne devront comporter qu'un seul 5gfy*'i- ''ans 'es cas ^es exccPi'°ns owes.L adjudication sera faite conformément a la loi.'-'adjudiVataire s'engage à payer les obliga-m capital cl intérêts courus, s'il y a lieu, par cquc W, payable au pair à Hauterive.however, should more than one rate be used, the amount issued at each eliffercnt rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.By-laws Nos: 187 \u2014 $28,400 \u2014 roads; 188 \u2014 $16,000 \u2014 roads; 189 \u2014 $78,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 190 \u2014 $7,000 \u2014 purchase of a pump; 206 \u2014 $152,000 \u2014 aqueduct, sewers; 213 \u2014 $2,000 \u2014 roads; 214 \u2014 $2,600 \u2014 roads.For adjudication only, interest will be calculated as from October 15, 1970.Table of redemption \u2014 5286,000 \u2014 20 years Year Capital October 15, 1971.$ 6,000 October 15, 1972.6,000 October 15, 1973.7,000 October 15,1974 .8,000 October 15, 1975.8,000 October 15, 1976.9,000 October 15, 1977.10,000 October 15, 1978.10,000 October 15, 1979.11,000 October 15, 1980.12,000 October 15, 1981.13,000 October 15, 1982.15,000 October 15, 1983.16,000 October 15, 1984.17,000 October 15, 1985.19,000 October 15, 1986.20,000 October 15, 1987 .21,000 October 15, 1988 .24,000 October 15, 1989 .26,000 October 15, 1990.28,000 Moreover, the following terms and conditions shall be considered: 1.Five-year, 10-year or 15-ycar short-term serial bonds.2.Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.3.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with the balance as 10-ycar short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.5.Ten-year serial bonds with the balance as 5-year short-term bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 6, the 20-year fixcel-term bonds shall not be for an amount less than $28,000, and if greater than the latter amount, said part must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of maturity.Also, the 5-year or 10-year short-term bonds shall comprise complete annual amortizations only, and starting with the last years of maturity, excluding the 20-year fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.i The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par in Hauterive. 5338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 .septembre 1970, 102' année, u\" .is 1a: capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banepic dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal à ou moindre de $28,000.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $28,000 les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 15 octobre de chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément, au tableau d'échéances de l'émission apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté, égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 5 octobre 1970, à 7.30 heures du soir, Salle des Conférences du conseil, 625, boul.Laflèchc, Hauterive, comté de Saguenay, P.Q.Lc conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Hauterive (Comté dc Saguenay), ce 10 septembre 1970.Ije .secrflaire-lrf.sorier, Gilbert Moffatt.Hôtel dc Ville, 625, boul.Luflèchc, Hauterive (Comté dc Saguenay), P.Q.Téléphone : 589-2071, code 418.36351 -o Capital and interest arc payable al ail branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as al I In |IPa,j ollice of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds for an amount equal to or less than $28,000.However, should they be issued partly as 20-year fixed-term bonds, for an amount greater than $28,000, (lie bonds so issued will be redeemable by anticipa, lion, at par, on October 15th each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturity of the issue upik-aring in this notice.Bach lender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of tlie amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.Tenders will be opened and considered at a meeting of llie council to be held Monday.October 5, 1970, at 7:30 o'clock p.m.in the Council's Conference Hull, 025 l.allcclie Boulevard, Hauterive, county of Saguenay, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Huiilerivc (County of Saguenay), September 10, 1970.Gilbert Moitatt, Secret arn-Treasurer.Town Hull, 025 Laflèchc Boulevard, Hauterive (Countv of Suguenav).l\\Q.Telephone: 589-2071.code 418.36351 Ville dc .M,mt-.|.di Comté de Matanc Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription < Soumissions pour obligations > seront reçues par lc soussigné Marcel Bélanger, greffier, Hôtel dc Ville, 30, Ave Hôtel de Ville, case postale No 1180, Mont-Joli, comté dc Matane, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 6 octobre 1970, pour l'achat de $67,500 d'obligations dc la ville dc Mont-Joli, comté dc Matanc, datées du 1er novembre 1970 ct remboursables par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990, inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à n' supérieur à 9x/z%, payable semi-annucllemcnt les 1er mai ct 1er novembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er novembre 1970.Town of Mont-Joli County of Mulmie Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by I lie undersigned Marcel Bélanger, clerk.Town I lull, 'ill Hotel de Ville Avenue, Post Ollice Box No.1180, Mont-Joli, county of Matane, P.Q,, until 8:00 o'clock, p.m., on Tuesday, October 6, 1970.for the purchase of an issue of $67.500 of bonds for I ho town of Mont-.loli.county of Matanc.dated November 1, 1970 and redeemable serially from NovcimVr 1, 1971 to November 1.1990 inclusively, with interest at a rate not less than S}S',.nor more than 9J^%.payable semi-annually on May l>t and November 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used.Hie amount issued at each different rale must cover one or several whole annual amorti/allons,!! shown on the table of redemption in ibis notice.For adjudication only, interest shall he calculated us from November I, 1970.Tableau d'amortissement \u2014 $67,500 \u2014 20 Année Capital 1er novembre 1971.$ 1,000 1er novembre 1972.1,000 1er novembre 1973.1,000 1er novembre 1974.1,000 1er novembre 1975.1,000 1er novembre 1976.1,500 1er novembre 1977.1,500 ans Table of redemption \u2014 $'i7,5lK) f\" Year '\"l\"lal November 1, 1971.s |IIIK' November 1, 1972.LQOO November 1, 1973.111 November 1, 1974.\\W November 1, 1975.November 1, 1976.I-., -November 1, 1977.l-m QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September JO, 1070, Vol.102, No.38 5339 1er novembre 1978.8 1,500 1er novembre 1979.1,500 1er novembre 1980.1,500 1er novembre 1981.1,500 1er novembre 1982.1,500 1er novembre 1983.1,500 1er novembre 1984.2,000 1er novembre 1985 .2,000 1er novembre 1986.2,000 1er uovrmbrc 1987.2,000 1er iiov.inbre 1988 .2,500 1er novembre 1989.2,500 1er novembre 1990.37,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 nus, ou 10 ans, ou 15 ans.2° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à terme lixe 20 ans.3° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde a court*' échéance 5 ans.4° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 10 ans pour une partie ct l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en séries 10 ans avec le solde à courte échéance 5 ans pour une partie el l'autre partie à ternir; fixe 20 ans.0° Obligations échéant en séries avec courte échéance 5 ans pour une partie et l'autre partie à terme lixe '20 ans.Toutefois, dans lc cas des paragraphes 4°, 5° et g°.les obligations échéant ii terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $3,500, et si supérieur à ce dernier montant, celte partie devra comprendre qu'un ou eles amortissements annuels entiers, en tenant compte ides tableaux d'échéances apparaissant dans le ' présent avis, cl en commençant par les dernières années d'échéances dc la partie renouvelable ci-après mentionnée.Également, les obligations émises à courte échéance 5 ans ou 10 ans, ne devront comporter que des amortissements annuels entiers, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant la partie qui sera à terme lixe 20 uns.Cependant, les soumissions ne devront être transmises «pic pour un seul des modes d'émission ci-haut el ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er novembre 1990, au montant de $37,500 comprend un solde de $35,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, cl échéant comme suit: Année Capital 1er novembre 1991.$ 500 1er novembre 1992.500 1er novembre 1993.1,000 1er novembre 1994.1,000 1er novembre 1995.1,000 1er novembre 1996.1,000 1er novembre 1997.1,000 1er novembre 1998.1,500 1er novembre 1999.1,500 1er novembre 2000.1,500 1er novembre 2001.1,500 1er novembre 2002 .2,000 1er novembre 2003 .2,000 1er novembre 2004 .2,000 1er novembre 2005.2,500 1er novembre 2006.2,500 er novembre 2007.2,500 er novembre 2008 .3,000 er novembre 2009 .3,000 1er novembre 2010 .3,500 November 1.1978.\t$ 1,500 November 1, 1979.\t1,500 November 1, 1980.\t.1,500 November 1, 1981.\t1.500 November 1, 1982.\t.1,500 \t November 1, 1984.\t2,000 \t November 1, 1986.\t.2.000 November 1, 1987.\t2.000 November 1, 1988.\t2,500 November 1.1989.\t.2,500 November 1, 1990.\t.37,500 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: 1.Five-year, 10-year or 15-year short-term serial bonds.2.Ten-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.3.Tcn-ycar serial bonds with the balance as 5-ycar short-term bonds.4.Ten-year serial bonds with the balance partly as 10-ycar short-term bonds and partly as 20-year fixed-term bonds.5.Ten-year serial bonds with the balance partly as 5-ycar short-term and partly as 20-ycar fixed-term bonds.6.Five-year short-term serial bonds for the one part and 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, in the case of paragraphs 4, 5 and 0, the 20-ycar fixed-term bonds shall be for an amount of not less than $3,500, and is higher than the latter amount, the said part shall comprise only one or more entire annual amortizations, bcarirg in mind the tables of maturities appearing in this notice, and starting by the last years of maturities of the renewable part hereinafter mentioned.Also, 5-ycar or 10-year short-term bonds shall include only complete annual amortizations, starting with the last years of maturities, excluding the 20-ycar fixed-term part.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The November 1.1990 maturity in the amount of $37,500 includes a balance of 835,000 renewable for an additional 20-ycar period, and maturing as follows: Year\tCapital November 1, 1991.\t8 500 November 1, 1992.\t500 November 1, 1993.\t1.000 November 1, 1994.\t.1,000 November 1.1995.\t1.000 November 1, 1996.\t1.000 November 1, 1997.\t1,000 November 1, 1998.\t, , , .1.500 November 1.1999.\t.1.500 November 1.2000.\t1.500 \t November 1.2002.\t2.000 November 1, 2003.\t2.000 November 1.2004.\t2.000 \t November 1,2006.\t, 2.500 November 1,2007.\t.2,500 November 1,2008.\t3.000 \t November 1, 2010____.\t.3,500 5340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, «\u2022 .« I,'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Mont-Joli.Lc capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont lc nom est mentionne dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation si elles sont émises par séries ou en séries ct terme fixe 20 ans, pour un montant égal ou moindre dc 837,500.Toutefois, si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 837,500, les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, lc 1er novembre de chaque année pour lc montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission, conformément aux tableaux d'échéances dc l'émission apparaissant dans lc présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt ct devra spécifier si lc prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts counts sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 158 \u2014 825,000 \u2014 contribution à un foyer d'hébergement; 183 \u2014 88,000 \u2014 aqueduc ct égouts; 194 \u2014 S34.500 \u2014 aqueduc ct égouts.Les soumissions seront ouvertes ct considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, lc 6 octobre 1970, à 8 heures du soir, Hôtel dc Ville, 30, Ave Hôtel dc Ville, case postale No 1180, Mont-Joli, comté de Matanc, P.Q.Lc conseil se réserve lc droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mont-Joli (Comté dc Matane), ce 4 septembre 1970.Le greffier, Marcel Bélanger.Hôtel de Ville, 30, Ave Hôtel de Ville, Case Postale No 1180, Mont-Joli (Matanc), P.Q.Téléphone: 775-5366, code 418.36206-37-2o The successful tenderer agrees Ici pay for H,c bonds, capital and accrued interest, if' any.by certified cheque payable at par at Moiil-Jçdi! ' Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Quebec of the bank mentioned in the loan proceilure as well us al the hc.nl ollice of the said bank in Toronto.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued serially or serially and as 20-ycar fixed-term bonds for an amount equal to or less than 837,500.However, if tbey are issued partly as 20-ycar fixed-term bond's for an amount greater than 837,500, the bonds so issued will be redeemable by anticipation, at par, on November 1st of each year for llie annual amount required to amortize the issue, pursuant to the tables of maturities of the issue appearing in this notice.Knch lender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and most specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery i included or not in the price of the lender.The said bonds shall be issued pursuant to the following by-laws: 158 \u2014 825.00(1 contribution to a sheltering home \u2014 1S3 8S.000 \u2014 aqueduct and sewers; 194 \u2014 834,500 aqueduct and sewers.The tenders shall be opened and consideredll a meeting of the council to be held on Tuesday, October 0.1970.at 8:00 o'clock, p.m.al the Town Hall.30 Hôtel de Ville Avenue, Post Office Box No.1 ISO.Mont-Joli, county of Matanc, P.Q.The council does not bind itself lo accept the highest or any of the tenders.Mont-Joli (Countv of Matanc), September I.1070.Marcel Bklaxokr, Clerk.Town Hall, 30 Hôtel de Ville Avenue, Posl Ollice Box No.1180, Mont-.loli (Matanc).P.Q.Telephone : 775-5366, code 41S.36206-37-1 Cite de Joliette Comté dc Jolicttc Avis public est par les présentes donné «pic des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par lc soussigné J.A.Désormicrs, secrétaire-trésorier, Hôtel dc Ville, Jolicttc, comté «le Joliette, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 5 octobre 1970, pour l'achat dc 82,327.500 «l'obligations dc la cité de Joliette, comté «le Jolicttc, datées du 1er novembre 1970, et remboursables par séries du 1er novembre 1971 au 1er novembre 1990 inclusivement, avec intérêt ù un taux non inférieur à 814%, ni supérieur à 914%, payable semi-annuellcmcnt les 1er mai ct 1er novembre «le chaque niinéc.Le taux «l'intérêt peut être lc même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, lc montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou «les amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau «l'amortissement dans le présent avis.Règlements Nos: 584 \u2014 813,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 587 \u2014 8473,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 591 \u2014 8199,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 710 \u2014 8396,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 711 \u2014 8234,000 \u2014 aqueduc, City of Jolicttc County of Jolicttc Public notice is hereby given that scaled tcmlcrs bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will lie received by the undesigned, J.A.Désormicrs, Secretary-Treasurer, CityBtJ Jolicttc, county of Joliette, P.Q., until 80) o'clock p.m., Monday.October a.1970, fort» purchase of an issue of 82.327.5lKI of bonds for the city of Joliette, county of Jolicttc, dated Novomiicr 1, 1970, ami redeemable serially front novembcr 1, 1971 to November I.1990 inch* vcly with interest at a rate not less than S i/o nor more than 914%, payable semi annually\" May 1st and November 1st of each year.i» late of interest may be the same for the Wis* issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each diffcreiil rule run* cover one or several whole annual amortiaW» ns shown on the tabic of redemption m W notice.By-laws Nos: 584 \u2014 813,000 loan rtneWJ 587 \u2014 8473,000 \u2014 loan renewal: 591 - WW - loan renewal; 710 - 1396,000 u«,u« « \u2022 sewers, roads; 711 - 823-1,00(1 ^aqwxiuft sewers, roads, lighting; 718 - $281,000 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 10, 1070, Vol.102, No.38 r^uls.voirie, éclairage; 718 \u2014 5281,000 \u2014 uaeduc, égouts, voirie, éclairage; 719 \u2014§281,000 -.bâtisses ct terrains; 720 \u2014 $193,500 \u2014 aciuc-iliic.égouts, voirie; 721 \u2014 $257,000 \u2014 voirie et éclairage._ \u2022olitic legally in-' corporated with its place of business at Ruisseau Vert, district of Hauterive, plaintiff, m HENRI PAUL JEAN, domiciled at Ruisseau Vert, district of Hauterive, defendant.Referring to two lots: 1.Lot 26, Range 1, Ragucncau Township, according to the official 5344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, u° 88 officiel Ferdinand Girard; 2° Le loi 21, rung 2, canto Ragueneau, d'aprcs le livre tic renvoi officiel Adclard Jean.1° Dc figure irrégulière étant le loi numéro 2C dc l'arpentage primitif borné vers le nord-ouest par le rang 2 ù l'est par le lot numéro 25 vers lc sud par la Rivière aux Outardes à l'ouest par lc lot numéro 27 mesurant treize ebaines et quarante-six mailles au nord-ouest, cinquante-quatre ebaines et cinquante mailles à l'est; cinquante-trois chaînes et soixante-quinze mailles à l'ouest; contenant en superficie soixante-neuf acres ct six dixièmes (09.6).Avec bâtisses ct dépendances dessus construites.* Sauf à distraire s partie dudit lot vendue par Philippe Ouellet à Antoine Portier mesurant en largeur 215 pieds et en profondeur 200 pieds, mesures anglaises plus ou moins ayant une superficie totale de 45000 pieds carrés Homes Nord par la route numéro 15; à l'est par le résidu dudit lot 2G rang 1, canton Ragueneau (appartenant à Jean Gagnon) au sud par la rivière aux Outardes, à l'est par une autre partie dudit lot numéro 20 rung 1, canton Ragueneau, ledit coté ouest se trouvant parrallèle et à distance dc 185 pieds de la ligne separative des lots numéros 20 et 27, rang 1, dudit cadastre.Avec une bâtisse dessus construite, circonstance et dépendances, 2° Lot 21, rang 2, canton Ragueneau, d'après lc livre dc renvoi officiel Adclard Jean: Étant lc lot numéro 21 de l'arpentage primitif borné vers lc nord-est par les lots numéro 17 ct 18; à l'est par le lot: 20 vers le sud-est par le rang 1; à l'ouest par lc lot numéro 22 vers lc nord-ouest par lc rang 3, mesurant dix-huit ebaines et soixante mailles au nord-est; soixante-quatre chaînes et cinquante mailles à l'est treize chaincs ct quarante-six mailles au sud-est quatre-vingt-une ebaines et cinquante-sept mailles à l'ouest deux ebaines ct quatre-vingt-trois mailles au nord-ouest; contenant une superficie de quatre-vingt-dix-huit acres (98.0).Pour être vendu au bureau du registratcur dc la première division d'enregistrement du comte dc Saguenay, au Palais dc Justice de Raie Co-mean, MARDI, .letVINGT-SEPTIÈME jour d'OCTOHRE 1970 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Tremblay.Baie Comeau, 14 septembre 1970.36352-0 Canada \u2014 Province dc Quélicc District de Hauterive Cour Provinciale, (\\/tUNICIPA LIT É 1) U No 7007.< -LV1 VILLAGE DE CHU-l TE AUX OUTARDES, corps politique légalement constitué ayant place d'affaires ct siège social sur son territoire ù Chute aux Outardes, demanderesse, rs LÉONARD BÈRU-BÉ, résidant ct domicilié à Chutes aux Outardes, district de Hauterive, P.Q., défendeur.Affectant le lot No 2-20, rang 1, canton Ragueneau, d'après le livre de renvoi officiel, Terre de la Couronne.Dc figure régulière borné vers lc nord-ouest par le lot No 2-16; vers le nord-est par le lot No 2-19; vers lc sud-est par lè lot No 2-31 ; vers lc sud-ouest par le lot 2-21 mesurant une largeur dc cinquante-cinq pieds (55') sur une profondeur moyenne dc quatre-vingt-deux (82') contenant une superficie dc quatre mille cinq cent dix pieds carrés mesure anglaise (4,510 p.c).Avec bâtisses, dépendances, circonstances.Pour être vendu au bureau du registratcur de la première division d'enregistrement du comté dc reference book, Ferdinand Girard; 2.|.0l 21 Range 2, Ragueneau Township, according to the official reference book, Adelard .lean.1.Of irregular shape is lot number 20 of llie original land measurement bounded lowanls the northwest by Range 2, in the east by loi number 25, towards the south by the Rivière aux Oular-des, in the west by lot number 27.measuring thirteen chains and forty-six links in lb,, nortli-west, fifty-four chains and fifty links in llie east; fifty-three chains and seventy-five links in n,c' west; comprising an area of sixty-nine acres ami six tenths (69.6).With buildings ami dependencies constructed thereon.\"Save ami lo v, ilhdruw\" from part of the said lot sold by Philippe (luellet to Antoine Portier measuring in width 215 fit! and 200 feet in width, English measurements mure or less, covering a total area of 45,000 square fed I bounded in the north by Roule number 15; fa the oust by the rest of lot 20 Range I, Kiigucneti | Township (belonging to Jean Gagnon), in tlie I south by Rivière aux Outardes, in lin- cast by I another part of the said lot number L'ii Range 1,1 Ragueneau Township,- the said western side being parallel and 185 feet distant from I he dividing line I between lots 26 and 27, Range I of I be sai.f I cadastre.With a building thereon cnii-lrurtcij, | circumstances and dependencies.2.Lot 21, Range 2, Ragueneau Township, I according to the official reference bunk.Adrlanl | Jean; 'Lot number 21 of the original laud meu-iirr-] ment is bounded towards the northeast by number 17 and 18; in the cast by loi 20, Unvanbl the southeast by Range I; in llie west by loll number 22 towards the northwest by Rangeai measuring eighteen chains and sixty links in ll*l northeast; sixty-four chains and fifty links in : I cast thirteen chains and forty-six links in I h I southeast eighty-one chains and fifty-seven linkil in the west two chains and eighty-three links bl the northwest; comprising an area of nincly-cigU1 acres (98.0).To be sold at the Registry Ollice of the firs'j registration division of Saguenay County, «I lail Buie Comeau Court House.TUESDAY, Hal TWENTY-SEVENTH day of 01TOHBR.IJf at TEN a.m.Raymond tiikmiii.ay, Sheriff's Office, Associate SheriJ.* Baic Comeau, September 24, 1970.1 Canada \u2014 Province of Québec District of Hauterive Provincial Court, f \\ MUNICIPALITY Ofl No.7007.< 1V1 THE VILLAGE Ofl t CHUTE a: X on AH DES, a body politic legally constituted linvingi| place of business and head office oh il5*enJ!j m Chutes aux Outardes, plaintiff r» LEONABg BÉRUBÉ, residing and domiciled at Chutes * Outardes, district of Hauterive.P.Q., defend* Referring to lot No.2-20, range I.Ibigiienei township pursuant to the official l»«ik of i rence.Crown bands., Of regular form, bounded towards iiiirtli«sj by lot No.2-16; towards northeast by lot x» 2-19; towards southeast by lot No.'-:{b lo**J southwest by lot No.2-21 measuring fifty* feet (55') in width by an average depth ofegf two feet (82'), containing a superficial are» four thousand five hundred and ten square! English measure (4,510 s.f.).\u201e_ With buildings, dependencies, eircumstaW To be sold at the registrar's ollice fort* * registration division of the county of bag* ¦In QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5345 bauciinv.uu Palais de Justice de Baie Comeau, MKHCHHDI.le VINGT-H UTTIÈME jour a\"0CT0BRE 1970, ù DIX heures de l'avant- Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Tremblay.Baie-Comeau, le 14 septembre 1970.36357 Canada \u2014 Province dc Québec District de Québec Cour Provinciale,) \"VMAISÔN RITE INC., No 47-49S.) cor|)oration légalement social l constituée, ayant son siège iss avenue I.anion tagne.Québec, li.tricl île Québec; demanderesse; rs RENE TREMBLAY, résidant sur la route 15 à Portneuf sur Mer, comté dc Saguenay, défendeur.Affectant le lot 29, borné au norel-est par le lot 29-1 mesurant 210', borné nu sud-est par le Fleuve St-I.uuront mesurant 90', borné au sud-ouest par le lot 27 mesurant 230', borné au nord-ouest par la route 15, ledit lot étant situé à Portneuf sur Mer, comté dc Saguenay, Ste-Aiuie de Portneuf, Seigneurie dc Mille Vaches, comté île Saguenay, rang B, Aveu bâtisses ct dépendances dessus construites.Pour être vendu au bureau du registratcur dc h première division d'enregistrement du comté île Saguenay, au Palais de Justice dc Baie Comeau.MARDI, le VINGT-SEFITÈME jour dfJCTOBRE 1970, à DEUX heures dc l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif.Raymond Tremblay.Haie Comeau.le 14 septembre 1970.36353-0 Canada \u2014 Province de Quéliec District dc Hauterive Gourde l'Echiquier^ T 'AFFAIRE DE LA LOI du Canada, ) Lj DE LTMJPOT SUR No LT-227-70.\\ LE REVENU ET MODI-\\ FICATIONS, demandeur et JEAN PAUL LAPRISE, domicilié à Sacré-Coeur, comté de Saguenay, P.Q., défendeur.Affectant tous les lots décrits sur les feuilles ci-anncxéos avec bâtisses, dépendances et circonstances, canton Albert, Sacré-Coeur.Loi: Plie 11.rang nord, chemin Albert.Le lot numéro onze (11) rang nord, chemin Albert, au cadastre officiel pour le canton Albert.A distraire l'emplacement, suivant, savoir: 1 Un emplacement situé du côté nord-est du chemini Albert, faisant partie dudit lot numéro «are (1 lie 11); mesurant cent pieds dc profondeur dans une première ligne nord-ouest, le long \"e la ligne de division du lot douze (12) rang nord, chemin Albert, audit cadastre; environ «ax (2) arpents dans une première ligne nord-«b soit plus exactement la distance qu'il y a à gmi'de la ligne de division entre lesdits lots «» (U) et douze (12) à aller jusqu'à la clôture net t environ soixante-quinze pieds au nord-¦* Margaer* River or Albert Road, on the north To withdraw however the emplacement bdm ging to Louis-Philippe Gauthi' r and olft* according to legal rights registered to aw, .division line of depth of this north purl soW*a» 1 Simard on the south goes perpew that of Paul simara on uie spurn b»\" T\"7ij cularly with the south line of loi twelve 1» QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5347 route île l'Anse de Roche pour aller aboutir à la lienc ouest du lot quatorze (14) de division avec B terre de Isate Perron à l'ouest; ladite partie nord ainsi décrite peut se borner comme suit, savoir: En front, au nord, partie au terrain dc Louis-Fliilippo Gauthier ou représentants et partie n lu route dc la rivière Stc-Marguerite; à la profondeur au sud, à la ligne droite perpendiculaire île division avec la partie sud des mômes lots de Paul Simard; tenant d'un côté, à l'est, à la route de l'Anse ele Roches; tenant d'autre cité, à l'ouest, à la terre de Isaïe Perron ou lot numéro quinze (15), rang sud, chemin et canton Albert.À distraire la partie vendue a M.J.-Thomas Castonguay suivant acte enregistré sous le No: 62006.sujet: Partie du lot numéro quatorze (Plie 14), rang sud, chemin et canton Albert.Lots: 17 et IS, rang nord, branche cal.\\° Une certaine terre située en la paroisse du Sacré-Coeur, comté de Saguenay, étant et composant le lot de terre numéro dix-sept (17) rang nord, branche est, canton Albert, ensemble avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.2° Une certaine terre située en la paroisse du Sacré-Coeur, comté de Saguenay, étant et composant le lot dix-huit (18) rang nord, branche est, canton Albert, ensemble avec toutes bâtisses dessus construites, circonstances ct dépendances.À distraire des lots numéros dix-sept ct dix-huit (17 et 1s), rang nord, branche est, canton Albert, deux lisières de terrain; contenant une niperficic totale de 214,577 pi.car.ou 4.926 acres M.A.Suivant quittance enregistrée sous lc No: 56450.Parties cédées au Ministère dc la Voirie de In Province dc Québec.Partir du loi 25, rang est, chemin Albert.Un terrain situé en le village du Sacré-Coeur, en le comté de Saguenay, à prendre ù l'est du chemin public et faisant front ù icclui, composant une partie du lot connu ct désigné comme étant le lut vingt-cinq dans lc rang est, chemin Albert, canton Albert et correspondant à une partie du numéro cadastral vingt-cinq (Ptic 25) dudit rang est, chemin Albert, canton All>ert; ledit terrain mesurant une largeur uniforme de ileux cent vingt-cinq pieds (225') anglais par une profondeur de cent pieds (100') anglais à partir audit chemin public, courant est, et borné comme suit ledit terrain, savoir; En front, à ouest, audit chemin public; à la profondeur à lest, a partie du même lot restant la propriété «le Louis-Pliilippe Maltais ou représentants; tennnt il un coté, au nord, à partie du même lot appartenant à Y van Desmeulcs; et d'autre côté, S n-' 1!1l)\"rlic ,lu même lot appartenant à iiiaililec Hovington, sans bâtisse.U 25 rang csl, chemin Albert, correspondant 0\" lot cadastral G/,3.r«,n!1Jm,.,T,!,lt' silué ù Sacre-Coeur, étant et ZiT'i .otInuméro vingt-cinq (25) rang est, emin Albert du canton Albert, correspondant leminC'v r ,\"1.Ving,t-cinq (25> dudit ra\"8 «t-*nm AU*rt et le lot numéro vingt-cinq (25) &,,« 8 est' chemin Albert, du canton auoiKsac correspondant au numéro cadastral s« cent quarante-trois (643).running along Anse de Roche Route to end on the west division line of lot fourteen (14) with the land of Isaïe Perron on the west; the said north part thus described may be bounded as follows, to wit: In front, on the north, part by the land belonging to Louis-Philippe Gauthier or representatives and part by Stc-Marguerite River Route; in depth on the south, by the straight division line perpcnelicular with the south part of the same lots belonging to Paul Simard; holding on one side, on the east by Anse de Roches Route; holding on another side on the west by the land belonging to Isaïe Perron or lot number fifteen (15), South Range, Albert Road and township.To withdraw the part sold to Mr.J.-Thomas Castonguuy according to a deed registered under No.62006, subject: Part of lot number fourteen (P.14), South Range, Albert Roud and Township.Lots: 17 and 18, North Range, East Branch.1.A certain piece of land situated in the parish of Sacré-Coeur, county of Saguenay, being and composing the lot of land number seventeen (17) North Range, East Branch, township of Albert, together with all buildings constructed thereon, circumstances and dependencies.2.A certain piece of land situated in the parish of Sacré-Coeur, county of Saguenay, being and composing lot eighteen (18) North Range, East Branch, township of Albert, together with all buildings constructed thereon, circumstances and elcpendencies.To withdraw lots numbers seventeen and eighteen (17 and 18), North Range, East Branch, township of Albert, two strips of land; containing a total area of 214,577 sq.ft or 4.926 acres E.M.According to a tlischargc registered under No.56450.Parts ceded to the Department of Roads of the Province of Québec.Part of lot 25, East Range, Albert Road.A piece of land situated in the village of Sacré-Coeur, in the county of Saguenay, to be taken on the cast of the public road and fronting the latter, composing a part of the lot known and designated as being lot twenty-five in the East Range, Albert Road, Albert Township and corresponding to a part of cadastral number twenty-five (P.25) of the said East Range, Albert Road, township of Albert; the said land measuring a uniform width of two hundred and twenty-five English feet (225') by a depth of one hundred English feet (100') from tlie said public road, running east, and the said land bounded as follows, to wit: In front, on the west by tlie said public road; in depth on the cast by part of the same lot remaining the property of Louis-Philippe Maltais or representatives; holding on one side, on the north, by part of the same lot belonging to Y van Desmaules; and on the other side, on the south, by part of the same lot belonging to Thaddéc Hovington, without a building.Lot 25, East Range, Albert Road, corresponding to cadastral lot 643.An immovable situated at Sacré-Coeur, being and composing lot number twenty-five (25) East Range, Albert Road of the township of Albert, corresponding to cadastral lot twenty-five (25) on the East Range, Albert Road of the township of Tadoussac corresponding to cadastral number six hundred and forty-three (643). 5348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n\" 88 Le vendeur cède en outre à l'acquéreur acceptant, tous les droits qu'il peut avoir sur une partie dc terrain se trouvant dans lc canton de Tadoussac, entre lc Trait Carré du rang est, du chemin Albert, et la rivière du Moulin à Baudc, ledit terrain étant à bail du gouvernement dc la province dc Québec, ct sujet à l'approbation du bailleur, M.Pierre Laprisc autorise par les présentes, lc transport dudit bail au nom de l'acquéreur.À distraire du lot vingt-cinq (25) les emplacements déjà vendus ct occupés par MM.Thaddéc Hovington, Yvan Desmculcs, Adélard Hovington, Dianis Gauthier ainsi que la partie déjà vendue au présent vendeur par M.Louis-Philippe Maltais antérieurement, le tout suivant les titres respectifs des susnommés.U faut dc plus distraire desdits immeubles: 1° La partie hypothéquée en faveur dc la Caisse Populaire du Sacré-Coeur suivant acte passé devant B.Landry, notaire, lc six mai mil neuf cent soixante-deux, et enregistré à Tadoussac sous lc numéro: 40202.2° La partie dc ces lots qui a été subdivisée suivant les plans de subdivision déposés au bureau d'enregistrement: Lc vendeur vend également à l'acquéreur les subdivisions: neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt ct un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-six, trente ct un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-six, trente-sept, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante, soixante ct un, soixante-deux, soixante-trois, soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six, soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante-dix, soixante ctonze, du lot numéro vingt-cinq (25-9, 25-10, 25-11.25-12, 25-13, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17, 25-18, 25-19, 25-20, 25-21, 25-22, 25-23, 25-26, 25-31, 25-32, 25-33, 25-34, 25-36, 25-37, 25-43, 25-44, 25-45, 25-46, 25-47, 25-52, 25-53, 25-54, 25-55, 25-56, 25-57, 25-58, 25-59, 25-60, 25-61, 25-62, 25-63, 25-64, 25-65, 25-66, 25-67, 25-68, 25-69, 25-70, 25-71) rang est, chemin Albert, au cadastre officiel pour lc canton Albert ainsi que les subdivisions: un, deux, trois, quatre, cinq, six ct sept dudit lot numéro vingt-cinq (25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6 et 25-7) mais sujettes, lesdites subdivisions, aux droits et servitudes des propriétaires riverains ct aux promesses de cession consenties en faveur dc la municipalité dc Sacré-Coeur.Il est déclare que les subdivisions vingt-deux et vingt-trois dudit lot numéro six cent quarante-cinq ainsi qu'une partie du lot numéro six cent quarante-trois sont affectées d'une servitude en faveur dc l'Hydro-Québcc résultant d'un acte passé devant Ale D.Giasson, notaire, le seize février mil neuf cent cinquante-neuf et enregistré à Tadoussac sous le No: 26719.Il faut dc plus distraire du lot numéro vingt-cinq (25) rang est, chemin et canton Albert.La partie hypothéquée en faveur de Lc Prêt Hypothécaire suivant acte enregistré à Tadoussac le trente ct un août mil neuf cent soixante-deux, sous lc numéro 41896.The vendor cedes moreover to the acccpliiii purchaser, all the rights which may exist on a part of the land found in the township of Tadoussac, between the \"trait carré\" of the East i{an\u201ef of Albert Road, and Moulin à Baudc Hiver the said lanel leased by the Government of tlie Province of Québec, and subject to approval by the lessor, Mr.Pierre Laprisc hereby authorized the transfer of the said lease to the same of thé purchaser.To withdraw from lot twenty-five (25) Hie emplacement already sold and occupied In-Messrs.Thaddéc Hovington, Yvan Dcsmeules, Adélard Hovington, Dianis Gauthier as well as the part already sold to the present vendor by Mr.Louis-Philippe Maltais formerly, the whole according to the respective deeds of the aliove-mentioned.One must in addition withdraw from the said immovables: 1.The part mortgaged in favor of the \"Caisse Populaire du Sacré-Coeur\" according to a deed passed before B.Landry, notary, on the sixth day of May, one thousand nine hundred and sixty-two, and registered at Tadoussac under number 40202.2.The part of these lots which was subdivided according to the subdivision plans deposited at the registry office: The vendor also sells to the purchaser sob-divisions: nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-six, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-six, thirty-seven, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six.forty-seven, fifty-two, fifty-tlircc, fifty-four, fifty-fire, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, seventy-one of lot number twenty-five (25-9, \"25-10, 25-11, 25-12, 25-13.25-14, 2515.25-16, 25-17, 25-18, 25-19, 25-20.25-21, 25-22, 25-23, 25-26, 25-31, 25-32, 25-33.25-34, 25-36, 25-37, 25-43, 25-44, 25-45, 25-46, 2547, 25-52, 25-53, 25-54, 25-55, 25-56, 25-57.2Ô-ÔS.25-59, 25-60, 25-61, 25-62, 25-63, 25-64, 25-65, 25-66, 25-67, 25-68, 25-69, 25-70, 25-71) East Kange, Albert Road, on the official cadastre for the township of AU>crt as well as subdivisions: one, two, three, four, five, six and seven of said lot number twenty-five (25-1, 25-2, 25-3, 25-4.25-5, 25-6 and 25-7) but subject the said subdivisions, to the rights and servitudes of riverain proprietors and to the promises of transfer granted in favor of the municipality of Sacré-Coeur.A declaration is made stating that subdivisions twenty-two and twenty-three of said lot nunilier six hundred and forty-five as well ;is a part \" lot number six hundred and forty-three are affected by a servitude in favor of Ilydro-Queltf resulting from a deed passed before Me V.Giasson, notary, on the sixteenth day of l-cbruary one thousand nine hundred and fifty-nine and registered at Tadoussac under No.2ÙÏ19, One must in addition withdraw from » number twenty-five (25) East Range, Albert Road and Township.\u201e .The part mortgaged in favor of Le ltt.Hypothécaire\" according to the deed registered at Tadoussac on the thirty-first day of August on thousand nine hundred and sixty-two, miner number 41896. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5349 Pour être vendu au bureau du registratcur de la première division d'enregistrement du comté iiav< au Palais de Justice dc Baie Gomeau, MERCREDI, le VINGT-HUITIÈME île SaguenâV, t i Palais de Justice dc Jlaic iu, M El l'OCTOBRE 1970, à DEUX heures dc jour u lupris-iiii.li., Le shérif adjoint.Bureau «lu Shérif, Raymond Tremblay.Baie Comeau, le 14 septembre 1970.36356-0 HULL ( 'anada \u2014 Province dc Quélicc District dc Hull Cour l'rovii.eiule, / WABGSL FILION, entre-Ç,P.03,375.) 1VX preneur électricien, ' domicile à Buckingham, district de Hull, el ayant payé toutes ses cotisations au Bureau des Examinateurs des Électriciens île la province dc Québec, et faisant affaires sous ks nom el raison de « Filion Électrique Enr.», demandeur, « PHILIPPE CORBEIL, domicilié au 16 de la rue Bourgogne à Hull, dit district, défendeur.« loi trois de la resubdivision officielle du lot trois eenl quarante-quatre dc la subdivision officielle du lot sept C (7C-344-3) du sixième rang, aux plan et livre de renvoi officiels du eanton de Hull, de forme irrégulièrc, borné au nord-ouest par le lot 7C-345, au nord-est par lc lot7('-3ll-l.au sud-est par le lot 7C-225 (rue), an sud-ouest par lc lot 7C-344-2; mesurant dix-sept pieds et vingt-trois centièmes (17.23') au nord-ouest, dix-sept pictls et sept centièmes 117.07') an sud-est, quatre-vingt-dix pieds (90') au sud-ouest el au nord-est; contenant en superficie mille cinq cent quarante-trois pieds carrés plus ou moins mesure anglaise (1,543 p.c).Avec bâtisses dessus érigées.» Pour être vendu au bureau du shérif, à Hull, district de Hull, le VINGT-DEUXIÈME jour d'OCTOBRE.1970, à TROIS heures dc l'après-midi.Ix shérif adjoint intérim., Bureau du Shérif, Jean-Guy Rochon.Daté, ce S septembre 1970.36299-q LABELLE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal Saisie immobilière v .( OÉRARD ROUX, plombier, ré-No .50 327.VJ si.iant ct domicilié au 5889 .de la rue Prébois, à St-Léonard, '(¦ nnr \u2022 \\'!,n,r°al, demandeur en garantie, ts '\u2022 HOI X I.TEE, cor|ioration légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires au 3020, Ie y'!\"'\"'- ville St-Michel, des cité et district de -Montreal, défenderesse en garantie.Avis de tente 'Immeuble situé dans le canton Lynch, comte \"Moelle, connu et désigné sous les numéros dZmUinqïai?nte & luarante ct un, rang (39, II) et 41, rg.2) au cadastre officiel du rantun Lynch.\u2022 dm an défendeur: au'^î ;'lr(, v,,'mlu-u\" hurcau d'enregistrement labis de Justice ù Mont-Laurier, comté ct To be sold a first registration nay, at the B WEDNESDAY, of OCTOBER, afternoon.Sheriff's Office, Baic Comeau, t the Registrar's Office of the division of the county of Sague-aic-Comcau Court House, on the TWENTY-EIGHTH day 1970, at TWO o'clock in the Raymond Tremblay, Assistant Sheriff.September 14, 1970.36356 HULL Canada \u2014 Province of Quebec District of Hull Provincial Court, ( \"\\/fARCEL CP.63,375.< AVI triciai ' domiciled at FILION, elcc-ian-contractor, at Buckingham, district of Hull, and having paid all his dues to the Board of Examining Electricians of the Province of Québec, and carrying on business under the trade-name of \"Filion Électrique Enr.\", plaintiff, vs PHILIPPE CORBEIL, domiciled at 16 Bourgogne Street, Hull, of the said district, defendant.\"Lot number three of the official re-subdivision of lot three hundred and forty-four of the official subdivision of lot seven C (7C-344-3) of the sixth range, on the official plan and reference book of the township of Hull, of irregular dimensions, bounded in the northwest by lot 7C-345, in the northeast by lot 7C-344-4, in the southeast by lot 7C-225 (street), in the southwest by lot 7C-344-2; measuring seventeen feet and twenty-three hundredths (17.23') in the northwest, seventeen feet and seven hundredths (17.07') in the southeast, ninety feet (90') in the southwest and northeast; comprising an area of one thousand five hundred and forty-three square feet more or less English measurement (1,543 s.f.).With buildings erected thereon.\" To be sold at the Sheriff's Office, at Hull, district of Hull, on the TWENTY-SECOND day of OCTOBER, 1970, at THREE o'clock p.m.Jean-Guy Rochon, Sheriff's Office Assistant Sheriff, a.i.Dated, Septemlicr 8, 1970.36299 L A It ELLE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal Seizure of immovables ( pÉRARD ROUX, plumber, re-No.750 327.< *J siding and domiciled at 5889 ' Prébois Street, in St-Léonard, district of Montreal, warranted plaintiff, M G.ROUX LTÉE, a corporation legally constituted, having its principal place of business at 3020, 41st Avenue, town of St-Michel, city and district of Montreal, warranted defendant.Notice of Sale \"An immovable situated in the township of Lynch, county of Labclle, known and designated under numbers thirty-nine, forty and forty-one.Range two (39, 40 and 41, Rg.2) on official cadastre for the township of Lynch.\" Notice to the defendant: To be sold at the registry office, Court House, in Mont-Laurier, county and district of Labclle, 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n\" 3S district dc Labclle, VENDREDI lc SIXIÈME jour dc NOVEMBRE 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Ia shérif intérimaire, Roland Matte.Bureau du Shérif intérimaire, Mont-I^iuricr, ce 4 septembre 1970.30297-O FRIDAY, the SIXTH day of NOVEMBER 1970, at TWO o'clock in the afternoon.Roland Matte, Acting Sheriff.Acting Sheriff's Office, Mont-Laurier, September 4, 1970.3(529; MONTRÉAL MONTREAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C /COMPAGNIE D'ASSURAN- (COMPAGNIE D'ASSIUAX.No 790-289.{ ^ CE SUR LA VIE LA SAU- No.790-289.\\ CE SUR LA VIE I.A S.U\\ t VEGARDE, corporation légale- \u2022 I VEGARDE, corporal ion legally ment constituée ayant son siège social au 152 est, rue Notre-Dame, en les cité et district dc Montréal, Québec, demanderesse, rs M.JEAN A.BISSONNETTE, administrateur, domicilié en la cité de Montréal, au 925 rue Chcrricr.défendeur, et HOME MORTGAGE & ACCEPTANCE CO.REG'D, corps politique dûment incorporé, ayant sa principale place d'affaires au 300 ouest, rue St-Jacques, en lu cité dé Montréal, Québec, mis en cause Un emplacement ayant front sur lu rue Visita* lion en la cité de Montréal, désigné sous le numéro sept cent quarante-neuf (749) sur le plan et au livre de renvoi officiels du Quartier Stc-Marie, avec la juste moitié de la ruelle St-Picrrc contiguë audit emplacement du côté nord-ouest et droit dc passage sur l'autre moitié dc ladite ruelle en commun avec ceux y ayant droit : Avec tous bûtiments dessus élevés, notamment une maison dc trois étages, portant le numéro civique 1591 dc ladite rue Visitation; Tel que le tout se trouve actuellement, avec tous droits y inhérents, avec toutes servitudes actives et passives s'y rattachant, plus spécialement avec et sujet à une servitude réciproque et perpétuelle de vue affectant tant l'immeuble sus décrit qu'un immeuble désigné comme étant la partie sud-est du lopin dc terre numéro sept cent cinquante (P.750) sur le plan et au livre dc renvoi officiels du Quartier Stc-Marie, relative à des fenêtres et portes se trouvant à une distance illégale entre les deux dits immeubles, telle qu'établie en un acte dc servitude intervenu entre le débiteur aux présentes et M.Alphonse Grenier, exécuteur-testamentaire de Dame Graziclla Cha-put, veuve d'Henri St-Georges, devant Me Jean-Paul Latour, notaire, le vingt-six mars 1964, dont copie enregistrée à Montréal sous le No 1737577.Pour être vendu nu bureau du protonotaire, cliambre #129, Vieux Palais dc Justice, en la ville de Montréal, lc VINGT ET UNIÈME jour d'OCTOBRE 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, lœ shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Mahtin.Montréal, 11 septembre 1970.36354-o Fieri Facias de Terris Vente par Licitalion Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal / A NDREW YEDYNAK, bou-No 793-704.\\ cher, résidant et domicilié ' en les ville ct district dc Montréal, demandeur, rs DAME MARY SLYWIN-SKA, femme de ménage, épouse divorcée dudit Andrew Ycdynak, résidant ct domiciliée en les ville et district dc Montréal, défenderesse.orporalion legally incorporated having its head ollice at 152 Noire-Dame Street East, in the city and district ol Montreal, Québec, plaintiff, is Mr.JEAN A.BISSONNETTE, administrator, domiciled in tlie city of Montreal, at 925 Chcrricr Street, defendant, and HOME MORTGAGE & ACCEP-TANCE CO.REG'D, body politic duly incorporated, having its principal place of business at 360 St-.Iacqucs Street West, in the city of Montreal, Québec, mis en cause.A lot fronting on Visitation Street in the city of Montreal, designated under number seven hundred and forty-nine (749) on the official plan and book of reference of Stc-Marie Word, including the exact half of St-Pierre banc contiguous to the saiel site on the northwestern side and riglit of way on the other half of the said lime in common with the rightful claimants; With all the buildings thereon constructed, in particular a three-story house, ben ring civic number 1591 of the said Visitation Street; As everything stands at present, with all tlie inherent rights, with all the active and |>as>ive servitudes thereby attached, more specifically with and subject to a reciprocal servitude in jjcrpctuity of the right of view affecting the immovable described above as well as I lie immovable designated as being the southeastern part of the plot of land No.seven hundred and filly (P.750) on the official plan and reference hook ol Stc-Marie Ward, relative to windows and doors which are placed at an illegal distance between the two said buildings, as established in 11 deed01 servitude drawn up between the debtor herein mentioned and Mr.Alphonse Grenier, executor, of Dame Graziella Chaput, widow of Henri » Georges, before Me Jean-Paul Latour.notary.on March the twenty-sixth, 1964.copy of whichn registered at Montreal under No.1737577.To be sold at the Office of the Protl.>tnry, room #129» the Old Court House, in I lie city ol Montreal, the TWENTY-FIRST day of Of T0-BER, 1970, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-M «nx,.Superior Court, Assistant SkerO.Montreal, September 11, 1970.363M Fieri Facias de Terris Sale by Licitalion Superior Court \u2014 District of Montreal ( A NDREW YEDYNAK, bat No.793-704.< -O- cher, residing and doue- I led in the city and to*\"*?Montreal, plaintiff, t>a DAME MAR\\ SLYA««j SKA, charwoman, divorced wife of the sw Andrew Ycdynak, residing and domiciled in «\" city and district of Montreal, defendant. QUlimCC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5351 « l*n emplacement ayant facade sur l'avenue Champagneur, en les ville ct district dc Montreal, rt compose dc: 1) I)u lut.numéro mule quatre cent quatorze de lu subdivision officielle du lot originaire numéro six cent, trente-sept (637-1414) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Laurent; mesurant vingt-cinq pieds de largeur sur une profondeur dc soixante-dix-neuf pieds et dix-sept centièmes sur sa ligne sud-est et soixantc-dix-liuit pieds et cinquante-sept centièmes de profondeur sur sa ligne nord-ouest Mesure anglaise et plus ou moins, ct: 2) De la partie sud-est du lot numéro mille quatre cent quinze dudit lot originaire six cent Irate-sept (S.E.P.637-1415) audit plan; mesurant cinq dixièmes d'un pied de largeur sur soixantc-dix-liuit pieds ct cinquante-sept centièmes île profondeur sur sa ligne sud-est et de soixantc-dix-liuit pieds et cinquante-six centièmes de profondeur sur sa ligne nord-ouest, mesure anglaise ct plus ou moins et bornée comme suit: À l'arrière au sud-ouest par un lot numéro 637-1423, en avant nu nord-est par ladite rue Cbanrpagncur, d'un côté au nord-ouest par le résidu dudit lot 637-1415 et de l'autre côté au sud-est par ledit lot 637-1414 ci-dessus décrit, tous audit plan.Avec une maison dessus érigée et portant les numéros civiques 8640 ct 8642 de ladite rue Champagneur ct dont lc mur nord-ouest est mitoyen sur une longueur dc vingt-huit pieds et soixante-sept centièmes.l.e vendeur réservant pour lui-même la mitoyenneté dudit mur.Ainsi que le tout subsiste présentement avec tous ses droits, membres ct appartenances, sans exception ou réserve d'aucune sorte dc la part du vendeur.Pour être vendu au bureau du protonotairc, chambre \u2022 129, au Vieux Palais dc .justice, en la ville de Montréal, le VINGT-DEUXIÈME jour d'OÇTOBRE 1970, à ONZE heures de (avant-midi.lliireaii du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Mahtin.Montréal, 11 septembre 1970.3635S Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Montréal ( XyfONTREAL TRUST COM-\\o 7884)19.4 1V1 paw, corps politique ct ^ dûment constituée, ayant son siegç socinl cl sa principale place d'affaires dans la vi le de Montréal, demanderesse, vs SANGUINE! AUTOMOBILE LIMITÉE, corps politi-Vk et dûment constitué, ayant son siège social et ?,pnwipalc place d'affaires dans la ville ct leilistriet de Montréal, en faillite, défemlcrcssc, et M.l 1ER! DION NE, syndic autorisé, dc la ville fi \u2022 aux P'an et 'ivre de rill i° « ™ ,lu (luurlit'r Sainte-Marie, dans la ni\u201el .i ¦!,\"!.lr«,l.mesurant soixantc-dix-huit 'ur l'a ,\"X\"''\"K'* «le pied de largeur en front .uI>l,M'au, et soixante-dix-neuf pieds «nq dixièmes de pied de profondeur sur sa [ \"X jTONTREAL TRUST COM-No.788-019A JVI PANY, a body politic and ' corporate, duly incorporated, having its head office and principal place of business in the city of Montreal, plaintiff, rs SANGUINET AUTOMOBILE LIMITÉE, a body politic and corporate, duly incorporated, having its head office and principal place of business in the city and district of Montreal, in bankruptcy, defendant, and ALBERT DIONNE, licensed Trustee, of the city and district of Montreal, in his quality as Trustee to the estate of the said Sanguinet Automobile limitée, mis en cause, ès-qualité, First: Papineau Avenue properly Two parcels of land in St.Mary's Ward in the city of Montreal known and described as follows: 1.(a) A part of lot number one thousand and ninety-eight (1098 Pt.) on the official plan and book of reference of the St.Mary's Ward in the city of Montreal, measuring seventy-eight feet und eight tenths of a foot in width in front on Papineau Avenue, and seventy-nine feet ami five tenths of a foot in width in rear by eighty- 5352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 septembre 1970, 102' aimée, n\" 88 ligne nord-ouest ct quatre-vingt-cinq pieds et six dixièmes dc pied de profondeur sur sa ligne sud-est, bornée en front par l'avenue l'apineau, à l'arrière par la rc-subdivision quatre de la subdivision douze dudit lot numéro mille quatre-vingt-dix-huit et en partie par une partie de la subdivision trois dc ladite subdivision dou/.c du lot mille quatre-vingt-dix-huit, au nord-ouest par la subdivision onze dudit lot mille quatre-vingt-dix-huit et dc l'autre côté, au sud-est, par la partie de la subdivision neuf du lot mille quatre-vingt-dix-huit décrite ci-après.b) La partie nord-est de la subdivision numéro neuf du lot numéro mille quatre-vingt-dix-huit auxdits plan ct livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, mesurant quarante pieds de largeur sur quatre-vingt-cinq pieds ct six dixièmes de pied dc profondeur sur sa ligne nord-ouest ct quatre-vingt-cinq pieds ct sept dixièmes de pied dc profondeur sur sa ligne sud-est, bornée en front par l'avenue Papineau, à l'arrière par la rc-subdivision un dc ladite subdivision numéro neuf du lot mille quatre-vingt-dix-huit, au nord-ouest pnr la partie du lot mille quatre-vingt-dix-huit décrite ci-dessus et au sud-est par la subdivision numéro huit dudit lot mille quatre-vingt-dix-huit.2.Un lopin dc terre se composant de: a) La subdivision numéro deux du lot mille quatre-vingt-sept (1087-2) auxdits plan et livre de renvoi officiels du quartier Saint-Marie; b) La subdivision numéro deux du lot numéro mille quatre-vingt-six (1086-2) auxdits plan ct livre dc renvoi officiels du quartier Sainte-Marie; e) Les re-subdivisions numéros deux ct trois de la subdivision numéro deux du lot numéro mille quatre-vingt-cinq (1085-2-2 et 3) auxdits plan et livre de renvoi officiels du quartier Saint-Marie; d) Les re-subdivisions numéros trois et quutrc de la subdivision numéro douze dudit lot numéro mille quatre-vingt-dix-huit (1098-12-3 ct 4) auxdits plan ct livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie; e) La rc-subdivision numéro un dc la subdivision numéro neuf dudit lot numéro mille quatre-vingt-dix-huit (1098-9-1) auxdits plan et livre dc renvoi officiels du quartier Sainte-Marie.Avec les bâtisses y érigées.Deuxièmement: Propriété de la rue Lafontainc Un certain emplacement faisant front sur la rue I.afontaine dans la ville dc Montréal et se composant des lots cinq cent dix-sept, cinq cent dix-huit, cinq cent dix-neuf, cinq cent vingt, cinq cent vingt ct un et cinq cent vingt-deux (517, 518, 519, 520, 521 et 522) auxdits plan et livre dc renvoi officiels du quartier Sainte-Marie.Avec la bâtisse y érigée portant les numéros civiques 1831 rue Dorion et 1965 rue lafontainc.Troisièmement: Propriété des rues Delorimier el Parthenais Trois lopins de terre qui sont les parties non subdivisées des lots originaires mille quatre cent quatre-vingt-treize, mille quatre cent quatre-vingt-quatorze, mille quatre cent quatre-vingt-quinze (1493, 1494 et 1495) auxdits plan ct livre de renvoi officiels du quartier Sainte-Marie, dans la ville de Montréal, connus et désignés comme suit: five feet and five tenths of a foot in depth in northwest line and eighty-five feet and six tenths of a foot in depth in its southeast line bounded in front by Papineau Avenue, in rear by rcsubdivi-sion four of subdivision twelve of said lot number one thousand and ninety-eight and partly by part of subdivision three of said subdivision twelve of lot one thousand and ninety-eight, to the northwest by subdivision eleven of the said lot one thousand and ninety-eight and on the other side to the southeast by the part of subdivision nine of lot one thousand and ninety-eight hereinafter described.(b) The northeast par of subdivision number nine of lot number one thousand and ninety-eight on the said official plan and bonk of reference of St.Mary's Ward measuring forty feet in width by eighty-five feet and six tenths of a foot in depth in its northwest line and eighty-five feet and seven tenths of a foot in depth in its southeast line, bounded in front by l'apineau Avenue, in rear by resubdivision one of said subdivision number nine of lot one thousand and ninety-eight, to the northwest by the part of lot one thousand anil ninety-eight hereinbefore described and to the southeast by subdivision number eight of said lot one thousand and ninety-eight.2.A parcel of land composed of: (a) Subdivision number two of lot one t housand and eighty-seven (1087-2) on tlie said ollieial plan and book of reference of the St.Mary's Ward; \\(b) Subdivision number two of lot number one thousand and eighty-six (10S6-2) on the said official plan and book of reference of the St.Mary's Ward; (c) Resubdivisions numbers two ami tln-rc of sulxlivision numl>cr two of lot number one thousand and eighty-five (1085-2-2 ami 3) on the said official plan and book of reference of the St.Mary's Ward; (d) Resubdivisions numbers three and four o( subdivision number twelve of said lot number one thousand and ninety-eight (1098-12-3 and 4) on the said official plan and book of reference of the St.Mary's Ward; (e) Resubdivision number one of the siihdivi-sion number nine of the said lot number one thousand and ninety-eight (1098-9-1) on the said official plan and book of reference of the St.Mary's Ward.With the buildings thereon erected.Second: Lafonlaine Street properly A certain emplacement fronting on I.afontaine Street in the city of Montreal and comprising lots five hundred and seventeen, five hundred and eighteen, five hundred and nineteen, five hundred and twenty, five hundred and twenty-one, and five hundred and twenty-two (517.5I\\ 519, 520, 521 and 522) on the said official plan and book of reference of the St.Mary's Want With the building thereon erected bearing civic numbers 1831 Dorion Street and 1965 I.afontaine Street Third: Delorimier and Parthenais Streets property Three parcels of land being unsubdivided parts of original lots numbers one thousand our hundred and ninety-three, one thousand lour hundred and ninety-four, one thousand our hundred and ninety-five (1493, 1494 and 145W on the said official plan and book of reference « the St.Mary's Ward in the city of Montreal, known and described as follows: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.38 5353 1.Une |Kirtic du lot numéro mille quatre cent (uiulro-vingt-trcize (1493), mesurant deux cent huit pieds sur une «le ses lignes sud-est, le long de In rue Dcmontigny, cent quarante pieds sur une île ses lignes sud-ouest, cent quarante pieds sur ton autre ligne sud-est, cent quarante et un pieds et vingt-cinq centièmes dc pied sur une autre lipie sud-ouest, lc long dc l'avenue Delorimicr, deux cent quarante pieds et cinquante-huit centième de pied sur une dc ses lignes nord-ouest, quatre-vingt-dix pieds et sixante-sept centièmes île pied sur son autre ligne sud-ouest, cent huit pieds cl soixante-sept centièmes dc pied sur son autre ligne nord-ouest, le long de la rue Logan, et trois cent soixante-douze pieds ct vingt-cinq centièmes de pied sur sa ligne nord-est, bornée comme suit : au sud-est par une partie non subdivisée du lot numéro mille (piatre cent quatre-vingt-treize sur la nie DcMontigny, ct par une autre partie non subdivisée dudit lot numéro mille quatre cent qualrc-vingt-trcise, avenue Delorimicr, ct par la subdivision seize dudit lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-treize, au nord-ouest par la subdivision seize dudit lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-treize ct par la rue Logan, nu nord-est par une partie non subdivisée du lot numéro mille (plaire cent quatre-vingt-treize.2.Une partie du lot numéro mille quatre cent (|Uutrc-vingl-quntorze (1494), mesurant dix-sept pieds sur une de ses lignes sud-est, trois cent soixante-douze pieds et vingt-cinq centièmes dc pied sur sa ligne sud-ouest, trente pieds sur sa ligne nord-ouest, deux cent quatre-x'ingt-buit pieds ct quatre-vingt-trois centièmes de pied sur une dc ses lignes nord-est, treize pieds et un dixième de pied sur une autre dc ses lignes sud-est et quatre-vingt-trois pieds et cinq dixièmes «le pied sur une autre ligne nord-est, bornée comme suit: nu sud-est par une partie non subdivisée du lot numéro mille (piatre cent quatre-vingt-quatorze, rue DcMontigny, et par une autre partie «lutlit lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-qualorzc, au sud-ouest par une partie non subdivisée du lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-treize, au nord-ouest par une autre partie non subdivisée du lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-quatorze, rue Logan, au nord-est par une partie non subdivisée du lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-quinze et par une autre partie dudit loi numéro mille quatre cent quatre-vingt-quatorze.3.Une partie du lot numéro mille quatre cent quatre-vingt-quinze mesurant trente-sept pieds et six dixièmes de pied sur une dc ses lignes sud-est, quatre pieds sur une de ses lignes sud-ouest, cent trois pieds ct soixante-quatre centièmes de pied sur son nuire ligne sud-est, deux cent qUatre-vmgl-huit pieds et ec.Bornée au nord-est par le lot 901/240 (rue Airlic).au sud-est par une pnrlie du lot 001, nu sud-ouest par les lois 001/258-5 et 901/258-4, au nord-ouest par le lot 1101/547.Mesurant quatre-vingt pieds (80') dans ses lignes nord-est cl sud-ouest, cent onze pieds (111') dans ses lignes Kiitl-est ct nord-ouest.Comprenant une superficie dc huit mille huit cent quatre-vingt pieds carrés (8,880 pi.car.) mesure anglaise.Le tout est tel qu'indiqué sur le plan No I).1945, référence 7009-008, en tinte du 10 septembre 1970 ct prépare pur M.Jean-Paul Anenault, arpenteur- géomèl re.Braull, Norbert.| 000/00-28.Avec hfitis.se dessus érigée, 140.rue Lurenle.Ciélimis, Roger.| 995/2073, 2074.Avec lmtissc dessus érigée, 320-331-333.9c Avenue.With building thereon erected.600-602-004, 12lh Avenue.003.01 690.52 30.10 88.67 1.318.80 With building thereon erected, 2258-2200, I.:i|iicrre.| 462.31 | 198.91 | 12.10 I 143.92 ! 807.30 A certain piece of hind of regular form being pari of lot 001 of the official cadastre of the parish of Lachine, registration division of Montreal, Province of Québec.Hounded on thc north-east by lot 901/240 (Airlie Street), on the south-east bv n part of lot 901.on the south-west bv lots 001/258-5 and 901/258-4.on the north-west by lot 901/547.Measuring eighty fect (80') in its north-east and south-west lines, one hundred mid eleven feet (111') in ils south-east and north-west lines.Forming an urea of eight thousand eight liunilreil and eighty square feet (8,880 sp.ft.), English measure.The whole as shown on plan No.I).1045.reference 7009-008, doled September 10.1070, and prepared by Mr.Jean-Paul Arsennult, hind surveyor.Lorocque, Armand (décédé-deceased)l 008/20.Avec bfttissc dessus érigée, 2048, rue Pigeon.Levis.Paul.| 974/349.Avec bâtisse dessus érigée, 8182-8184, rue Dora.Loren/.o.Salvatore.| 971/308.Avec bâtisse dessus érigée, 2188-2190, rue Lise.Morin.Mme-Mrs.Liliane.| 971/395.Avec bâtisse dessus érigée, 8880-8882, rue Curé-Legnull.Pcrrin, Henry.| Camp /04.Situé sur l'Ile aux Hérons.200.12| 218.50 | 14.44 | 33.20 | MO.» With building thereon erected, 140, Lnrenle .| 401.71 | 550.28 | 45.40 | 02.41 I 1.059.S6 With building thereon erected, 320-331-333, 9th Avenue.| 550.05 | 251.59 | 30.00 | 100.60 | 040.03 With building thereon, erected, 2048, Pigeon.730.82 | 032.80 | 33.82 | 131.05 | t.129 09 With building thereon erected, 8182-8184.Dora.1.320.35 | 455.08 | 33.87 | 42.04 | 861.W With building thereon erected, 2188-2190.Lise, .| 670.00 | 434.83 | 32.73 | 00.47 | 1.234-53 With building thereon eroded, 8880-88S2, Cu* Leguull.| 3.02 | 0.13 | 0.08 Situated on Herons Island.13.13 2.1.80 Donné à LaSallc, ce 14c jour dc septembre Given at LaSallc, this 14th day of September, 1970.1970.Le greffier, Jacqueline: Giouèhb, 30349-38-2-o jacqueline Giguère.36349-38-2-0 City Clerk. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.88 5365 INDEX \\o 38 ASSOCIATIONS cooperatives COOPERATIVE Associations .5319 .5319 .5320 '.-Inc.).5230 VMS divers ' MISCELLANEOUS Notices Hugotvillo, ville-town (Rachat d'obligalions-Redeinption of bonds).5301 Chevaliers de Colomb de Montréal-Nord, conseil Mercier No 33701 (Régi.).5301 Estate of Cilles Gauthier.5321 Estate of Gérard Tardif (Benefit of Inventory).5302 Knights of Columbus of Montreal North, Council Mercier No.33701 (By-laws).5301 Succession Gilles Gauthier.5321 Succession Gérard Tardif (Bénéfice d'inventaire).5302 Valcourt, village (Barrage-Dam.).5302 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demander.Applications: Braun, Margaret Selma.5315 Cross, Francis Michael.5315 Gauthier, Georges Lorient.5315 Slùldkroiit, Samuel.5315 CHANGEMENT DE NOM \u2014 1-oi du Accordés: CHANGE OF NAME ACT Granted: Asher.Jeffrey Noah.5315 Dernier, Robert Emile.5316 (linrctte, Marie Matilde Paulcttc.5316 Chen.Chi-Ting.5316 Diamond, Irving Martin.5316 Dollin.Eugene.5316 Kng, Jack Shin Yick.5316 (iuguon, Marie Joseph Alfredine Nadine.5316 (i.hvin, William.5317 Kime.Henry George.5317 Lanthier, Jean Pierre.5317 Ostro.Martin George.5317 Pelletier, Joseph Antoine René.5317 l'etin.Roger Aimé.5317 COMPAGNIES Chartes \u2014 demandes d'ahundon dc COMPANIES Charters \u2014 Application for Surrender of Agences publicitaires du Nouveau Quélicc (I/»s).Boulangerie Stc.Adèle Itée.Canada Auto Leasing Co.Ltd.Canadan Furniture Co.Ltd.Charlcsbourg Parts & Accessories Ltd.Charlcsbourg pièces & accessoires ltéc.Cité Rambler inc.Club île golf St-Georgcs inc.Combustion Utilities Corp.of Québec .Comité de Stc-Foy pour le centenaire de la ( onfédération.Cotton h'rocks Inc.Coulure automobile ltéc.Editions Albert inc.(Les).Furniture Italian Style Inc.Gagné (M.G.) inc.Investissements Rimouski inc.(Les).Journal-Administration Itée.Lubrimar inc.Marché St-Pierre Itée.Meubles de style italien inc.(Les).Ouellet & Labergc Itée.Jjaeine (Louis Philippe) démolition inc.«an Mar Mines Ltd.aogetrem Inc.5304 5302 5304 5304 5303 5303 5304 5304 5305 5305 5303 5305 5302 5303 5303 5305 5303 5303 5304 5303 5305 5306 5305 5306 Dissoutes Dissolved Aide Financière Laro ltéc.5300 Feuchtwangcr Properties (Québec) Ltd.5300 FTect Transportation Services Ltd.5300 Hershey Construction Company.5300 Matériaux construction Macamic inc.5301 Munlin Investment Corporation.5301 St-Martin Equipment & Supply Limited.5300 Divers Miscellaneous Apparel Salesmen's Markets Inc.(Rcgl.- By-lairs).5310 Association sportive Lanoraic inc.(L') (Règl.-By-laws).5306 Bocage Construction Inc.(Dir.).5306 Bois Nor-Mat inc.(Dir.).5310 Brianyl Ltd.(Dir.).5311 CKTS Radio Sherbrooke ltéc (Norn-Name ch.).5306 Canadian Personal Loan & Finance Company Inc.(Dir.).5311 Choqucttc automobile inc.(Nom-Namc ch.).5310 Club radio amateur dc Thctford Mines (Règl.-By-laws).5307 Construction Bocage inc.(Dir.).5306 Corporation d'épargne et de placement nationale (Dir.).5307 5366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n\" 38 Divers Miscellaneous (suite) (continued) Cravat (Montréal) Inc.(Dir.).5311 Crclinstcn Fruit Company (Dir.).5306 Deschênes & Fils (1969) ltéc (Dir.).5307 École Saint-Jcan-Bosco (Règl.-By-laics) 5309 Entraide des associés dc Trois-Rivières inc.(L') (Règl.-By-laws).5307 Fédération des monastères des chanoi-nesses régulières hospitalières de la miséricorde de Jésus de l'ordre de St-Augustin (La) (Règl.-By-laws)., .5307 Fondation du Mauricien médical (Règl.-By-laws) .5308 Giffcn Recreation Limited (Name ch.).5309 Giffcn Récréation limitée (Nom ch.).5309 Heller-Natofin Ltd.(Dir.).5311 Hollywood Star Knitting Mills Ltd.(Dir.).5311 Hôpital du Sucré - Coeur, Montréal (Règl.-By-laws).5312 Hôtel Cliamplain inc.(Dir.).5311 Immeubles Terroir inc.(Les) (Nom- Name ch.).5310 Kiwanis Club of Granby, Inc.(Règl.-By-laws) .5308 Lafcrte (J.A.) (1970) Ltd.(Name ch.).5311 Laferté (J.A.) (1970) ltéc (Nom ch.).5311 Laviolette, Laberge inc.(Nom-Namech.) 5309 Linton Service Station Ltd.(Dit.).5307 Nagley Inc.(Nom-Name ch.).5308 National Savings and Investment Corporation (Dir.).5307 Nor-Mat Lumber Inc.(Dir.).5310 Ogilvy & Mather (Québec) Limited (Nom-Name ch.).5309 Piazza (Joseph) Construction inc.(Nom-Namech.).5308 Place Racine (sur la côte) limitée (Règl.-By-laws).5308 Provincial Production & Die Inc.(Dir.).5309 Publications Dumont inc.(Dir.).5308 Québec Racing Drivers Association Inc.(The) (Règl.-By-laws).5310 Sheiners Incorporated (Dir.).5310 Styles Pads Inc.(Dir.).5309 Surveyer, Nennigcr, Chenevert inc.(Dir.).5311 Lettres patentes Letters Patent Agence Haudmel inc.5252 Agences distribution C.R.R.inc.5252 Agences St-Maurice inc.(Les).5253 Aménagements Trois Lacs inc.(Les) .5253 Amis dc l'Institut Philippe Pinel (Les).5253 Arches laminées du Québec inc.(Les).5254 Asphalte Gilles Boisvert inc.(L').5254 Assurance accident G.Boudreau inc.5255 Bêchai Itée.5254 Astrorama Guild Ltd.5271 Belcc Bowling Club Inc.5261 Bertec inc.5255 Best Theatre Supply Inc.5255 Boudreau (G.) Accident Assurance Inc.5255 Boutique Au Vieux Grenier inc.5256 Bo-Vi Investments Ltd.5283 Brindamour (W.) inc.5256 Buckland Metal Inc.5256 Busmac Inc.5257 Cafétérias Rotavc Itée (Les).5257 Canapoma Ltd.\".5257 Carrier (Jean-Paul) inc.5258 Centre de carte Saberton Itée.5286 Centre dc moto-neige Stc-Marthc inc.5258 Centre de pneu Asbestos inc.5285 Chalifour (Gilles) Limited.\u2022.5259 Chalifour (Gilles) limitée.5259 Cliambly Mould & Die Inc.5259 Clinique de Médecine familiale d'Alma inc.(La).5259 Club Aquanautcs inc.5260 Club d'auto-ncige Lac-des-Plagcs.5260 Club dc natation Godefroy inc.5260 Club de quilles Belec inc.(Le).5261 Club dc Ski le Petit Chamonix (Le) .5261 Club la Rencontre dc Mont-Joli, inc.(Le).,;.5262 Club optimiste du Plateau Mont-Royal, Québec inc.5262 Club Plein Air Spec inc.5262 Compagnie des grossistes en alimentation inc.(La).5263 Construction Bcaubicn ltéc.5263 Construction Marmico inc.5263 Corporation du Cimetière de Chicoutimi-Nord.:.5290 Couvre planchers Quebar inc.(Les).5264 Dame auxiliaires du Foyer des Années d'Or dc Kénogami inc.(Les).5264 Dames auxiliaires de l'hôpital Santa Cabrini (Les).5277 Delmar Forwarding Corp.5264 Dessau Holding Ltd.5270 Diako & Sons Maintenance Company Limited____.5265 Dieairc (Jean) inc.5265 Dussault & Lamourcùx (1970) inc.5265 Echohamok Inc.5266 Entrepôt des aubaines CM.inc.52G6 Entreprises Lacharité Itée.5266 Équipement By-Ro limitée.5267 Ever Klin International Heated Wipers Inc.5267 Félix Auto Service Inc.5267 Fermes Desrivières, ltéc.5268 Fortune Films Productions Inc.5268 Frank Auto Body Inc.5269 G.P.Aluminium Inc.5269 Gagnon frères meubles (Baic-Comeuu) Itée.5269 Gestion Dessau Itée.5270 Geoffroy-Valois Itée.5270 Granby Pulp & Paper Company.52i0 Guild of Commercial Accountants.5271 Guilde Astrorama Itée.5271 Guilde des comptables commerciaux (La).,.5271 Haudmel Agency Inc.°JjJJ Hélicoptères Olympiques limitée.5281 Houscco Industries Inc.5271 Imavox inc.5272 Immeubles Studio-2001 inc.(Les).5272 Importations Polarin Itée (Les).52/2 Imprimerie St-Patrice inc.52/3 Independent Petroleum (1970) Ltd.5273 Industries Laurier Itée (Les).5173 Industries automotrices du Québec limitée (Les).5284 Industries Nasral Itée (Les)._>27j Inga Metals Limited.\u2022 ¦ 5274 Institut scientifique de soins esthétiques du Québec Itée.«275 International Lift Truck Inc.»?L5 Jean & Rochcttc inc.Jet Copy House Ltd.«5^6 Journal Rond Point inc.°2ïo Kcbcc Fasliion Discount Ltd.5276 Kramkimel (Jacques) Insurance Agency Ltd.u2\" QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, September 19, 1970, Vol.102, No.88 5367 Lettres patentes Letters Patent (suite) (conlinued) 1 ulics' Auxiliary of Santa Cabrini Hos- ' pitul (The).5277 Laurentian Lanes Ltd.5278 Laurier Lidustrics Ltd.5273 Lcvcrt Transport Inc.5278 Lifare Realty Corp.5278 Lignery Paper Inc:.5282 Major & Martin inc.5279 Mandarin Cine-Art Enterprises Ltd.5279 Mandro inc.5279 Manufacture d'habits des Deux Montagnes ltéc.5280 Marché Gilles Boisvert inc.5280 Mason Shoe Jobbers Inc.5280 Miller & Morris Inc.5281 Modem Service Auto Repairs Inc.5287 Morin (Gérard) inc.5281 Nasral Industries Ltd.5274 Normick (J.H.) inc.5281 Olympic Helicopter Limited.5281 Papier Ligncry inc.5282 Pétroles indépendants (1970) ltéc (Les).5273 Pierre-Gérard bijoutiers inc.5282 Pierre-Gérard Jewellers Inc.5282 Placements Bo-Vi Itée.5283 Polygesco Inc.¦ \u2022 \u2022 5283 Prêts économiques Mont-Rolland inc.(Les).,.5283 Productions Super M inc.5288 Quélicc Automotive Industries Limited.5284 Quéhee autorama inc.5284 Québec Laminated Arches Inc.5254 Quincaillerie la Péradc inc.5284 R.l).Design & Seal Inc.5285 Resalnc.5285 Restaurant Beltrano inc.5285 Rohac inc.(Correction).5312 St-Mauricc Agencies Inc.5253 Sabertons Card Centre Ltd.5286 Salon de Quilles Laurcntien Itée.5278 Sauna-Craft Ltd.5286 Service d'entretien de Verdun inc.5286 Service de réparations d'autos Moderne inc.5287 Services de rénovation Trapèze ltéc.5287 Société de Recherches en Télésystèmes.5287 Stephanie Handbags Co.Ltd.5288 Super M Productions Inc.5288 Ter-Ra Development Corporation.5289 Tcchmatc inc.5289 Torono Homes Inc.5289 Lettres patentes Supplementary supplémentaires letters Patent Artisan 67 inc.5290 Association des Manufacturier dc Produits Laitiers du Québec inc.- 5290 Association des Bibliothèques Publiques et des Centres Culturels du Québec inc.(L').5290 Auberge (St-Jérôme) inc.5291 Autoski inc.5291 Caprivc Industries and Resources Limited.5291 Carrière Hébert inc.5291 Crédit Stanstead inc.5292 Cuisines Roi du Nord inc.(Les).5292 Délicieuse limitée.5293 Delicious Food Products Limited.5293 Dcspatis Transport limitée.5292 Dubuc Tank Lines Ltd.5292 Dumont Express Ltd.5292 Dumont Express Itée.5292 Entreprises Rolland Joyal & Fils inc.(Les).5293 Exclusive Silks Inc.5293 Floor Service Inc.5297 Elizabeth T.Greensbiclds Memorial Foundation (The).5293 Grand Prix Handbags Inc.5297 Grapholith Inc.5293 Loignon, Durand & Qucvillon inc.5294 Ménard (R.) Transport Itée.5294 National Service of Hôtesses Inc.5297 Oasis de l'Enfance (St-Cyprien) inc.(L') 5294 Plateaux dc la Ferté inc.(Les).5294 Produits Gailuron inc.5295 Quality Knitwear Co.Ltd.5295 Québec Dai ray Products Manufacturers' Association Inc.5290 Québec Lait inc.5295 Québec Milk Inc.5295 Ravik inc.5295 Rhéault & Frères limitée.5295 Richelieu Fabrics Limited.5296 Rita Fleuriste (Sherbrooke) inc.5296 Roy & Frères Joliette ltéc.5296 S.O.- S.Distribution Inc.5296 Sacs à Main Grand Prix inc.(Les).5297 Service dc Planchers inc.5297 Service de Soins à Domicile des Laurentides inc.5297 Service National des Hôtesses inc.5297 Simard & Voyer inc.5297 Socavie inc.5298 Société de Placements Dentura inc.(La) 5298 Société de Placements Dentura inc.(La) 5298 Stanstead Credit Inc.5292 Starto-Jet Inc.5298 Swabian Corporation.5299 Thêta Delta Çhi (McGill).5299 Tissus Richelieu limitée (Les).5296 Vachette Metal Inc.5299 Versailles inc.5299 Wiljoy Realty Corp.5300 Sieges sociaux Head Offices Ariens Canada Ltd.5314 Ariens Canada Itée.5314 Christmas Carols Inc.\u2022.5314 Cinévision Itée.5313 Corporation dc placement Panel.5312 Cour Mailloux inc.(À la).5312 Fondation Universitas du Canada.5313 Gingras (R.) & associés inc.5314 Leclerc (René) Construction inc.5314 Nocma inc.5314 P.R.I.M.E.Energy Systems Ltd.5313 Panel Investment Corporation.5312 Publications Dumont inc.5312 Restaurant la grenouille et le boeuf (Québec) inc.5313 Sorel Investment Corp.5315 Systèmes d'énergie P.R.I.M.E.ltéc.5313 Telecon (Trois-Rivièrcs) inc.5313 Universitas Foundation of Canada.5313 Vieux Noëls inc.(Les).5314 DEMANDES APPLICATIONS à la Législature to Legislature Congregation Beth Tikvah.5317 Église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières .5318 Estate of Mathilde Cormier.5318 Succession Mathilde Cormier.5318 5368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 septembre 1970, 102' année, n° 88 LIQUIDATION WINDING UP avis dc Notices Société coopérative agricole Ste-Scholastiquc.5319 MINISTÈRES DEPARTMENTAL Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Colombourg (Acc.-Grant.).5322 Us-Deux-Rivcs (Acc.-Grant.).5323 Saint-Blaisc (Acc.-Grant.).5322 Saint-Cléoplias (Acc.-Grant).5323 Industrie Industry ct Commerce and Commerce Avis de pêche aux coquillages.5320 Shell fishing notices.5320 Terres ct Forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Humqui,.ennton-township.5318 Pointc-aux-Trcmbles, par.5319 St-Antoine
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.