Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 28 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1970-11-28, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 102e année vol.102 I 3UEBEC \"iUEBEC N° 48 6791 hiette officielle à Québec QUEBEC OFFICIAL GAZETTE Québec, samedi 28 novembre 1970 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue lu traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter lu facture sur réception et avant la' deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.G° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandai a l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire ù midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officie] du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans Une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d an Ire des frais onéreux de reprise.Québec, Saturday, November 28, 1970 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements arc payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like arc payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazelle is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher, reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE, Québec Official Publisher 0792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970,102' année, n° 4S Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 35 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 270 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 15 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: 84 des 100 mots.Exemplaire séparé: 81 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre, S20; du 1er avril au 31 décembre.S15 et du 1er juillet au 31 décembre, S10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Ix premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocii Lefebvhe.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1909 33015 \u2014 l-52-o Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion : 35 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 270 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 15 cents |>cr agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc) at double rate.Translation: 84 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods: From Januarv 1st to December 31st, S20; April 1st to December -ilst, 815 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rock Lefebvre, Quebec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1909 33015 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif île la troisième classe (permis No 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107).Lettres patentes A P A Jonquil-re limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 15c jour de septembre 1970, constituant en corjx)-ration: Léonard Rivcrin, commerçant, 40, rang Ste-Annc, Philippe Guay, voyageur de commerce, 157B, St-Simon, tous deux de Jonquière, et Martin Girard, comptable, 254, Yaudrouil, Arvida, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes les parties et accessoires d'automobiles, de même que toutes espèces «le machines, instruments, outils, appareils et accessoires, sous le nom de « A P A Jonquière limitée », avec un capital total de 840,000, divisé en 300 actions ordinaires de 8100 chacune et en 100 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Jonquière, district judiciaire de Chieoutimi.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Al.deht gaonon.37391-0 436-1970 A.R.Cafétéria inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 24e jour d'août 1970, constituant en corporation: André Rivest, restaurateur, 14, 8c Rue, Crabtree, Julien Fauteux, comptable, 75, St-Charlcs nord, et Monique Frechette, secrétaire, fille majeure, 274, St-Marc, ces deux derniers de Jolictte, pour les objets suivants: Letters Patent A P A Jonquière limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date I lie 15th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Leonard Riverin, merchant, 40 Stc-Anne range, Philippe Guay, commercial salesman, 157B St-Siiaon, both of Jonquière, and Martin Girard, accountant, 254 Vaudreuil, Arvida, for the following purposes: To deal in all kinds of automobile parts and accessories, as well as all kinds of machines, instruments, tools, appliances and accessories, under the name of \"A P A Jonquière limitée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Jonquière, judicial district of Chieoutimi.J.-Al.beht Gaokok, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai in*.37391 436-1970 A.R.Cafétéria inc.Notice is given that under Purl I ol the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Rivcst, restaurateur, 14, 8th Street, Crabtrcc, Julie» Fautcux, accountant, 75 St-Charles North, and Monique Frechette, secretary, spinster of the full age of majority, 274 St-Marc, the latter two of Joliette, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1070, Vol.102, No.L8 0793 Exploiter «les cafétérias, restaurants, tavernes, auberges, hôtels, salles à repas et salles à manger, sou- le nom de « A.R.Cafétéria inc.», avec un capital total de S60.000, divise en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 5,000 actions privilégiées de S10 chacune.I.c siège social de la compagnie est C.P.500, 1ère Avenue, Crabtree, district judiciaire de Joliçftç./.c sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.3731)1-0 3611-1970 L'Académie Normand Iludon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies el cooperatives donne avis, qu'en vertu ile la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 28c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Normand Hudon, artiste, rang des Trente, lîeloeil.lean Vale, annonceur, 7710, Des Vendéen-.Anjou, et André Bcrgevin, administrateur, 8715, Barbeau, Saint-Léonard, pour les objets suivants: faire affaires comme exposants et vendeurs de tableaux, sous le nom de « L'Académie Normand Hudon inc.», avec un capital total de S M 1.1 H10.divisé en 100 actions ordinaires d'une videur nominale de S10 chacune et en 3,900 actions privilégiées d'une valeur nominale de $111 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal./.r siiii.i-niini.slre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 4224-1970 Aéroport du comté de Lévis liée Levis County Airport Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnie- cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, d a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Claude-A.Blanchard, avocat.1187, boulevard Saint-Cyrille ouest, Sillery, Danielle Clia-pul.840, Cosot, et Diane Beaupré, 1440, Bardy, \u2022 es deux dernières secrétaires, filles majeures, de Quebec, pour les objets suivants: Exploiter des aéroports et lignes aériennes, sous le nom de « Aéroport du comté de Lévis liée \u2014 Lévis County Airport Lid.», avec un capital total de S40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions privilégiées dë $10 chacune.Lé siège social de la compagnie est à Saint-\u2022can-Cliiy.sostomc, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Bouchard.S^l-o 4G98-1970 Alma Varieties Inc.Variétés Aima inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu ne la première partie de la Loi des compagnies, M a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Armando Capcllo, agent, 8560, avenue orown, André Boucher, technicien, 1470, rue Jnierry, ct Amerigo Capcllo, commis, 1574, me tancourt, tous les trois de LaSalle, pour les otijets suivants: To operate cafeterias, restaurants, taverns, inns, hotels, lunch-rooms and dining-rooms, under the name of \"A.R.Cafétéria inc.\", with a total capital stock of $60,000, divided into 10,000 common shares of SI each and into 5,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at P.O.Box 500, 1st Avenue, Crabtree, judicial district of Jolictte.J.-Albert Gagnox, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3011-1970 L'Académie Normand Iludon inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Normand Hudon, artist, de Trente Range, Beloeil, Jean Yalc, announcer, 7710 Des Vendéens, Anjou, and André Bcrgevin, administrator, 8715 Barbeau, Saint-Léonard, for the following purposes: To carry on business as painting exhibitioners and sellers, under the name of \"L'Académie Normand Hudon inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 100 common shares of a nominal value of S10 each and into 3,900 preferred shares of a nominal value of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Ai.beut Gaonon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4224-1970 Aéroport du comté de Lévis Itée Lévis County Airport Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude-A.Blanchard, advocate, 1187 Saint-Cyrille Boulevard West, Sillery, Danielle Chaput, 840 Casot, and Diane Beaupré, 1440 Bardy, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority of Québec, for the following purposes: To operate airports and air-lines, under the name of \"Aéroport du comté de Lévis ltée \u2014 Lévis County Airport Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of S10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Jcan-Chrysostome, judicial district of Québec.Ls-PiiiLii'i'i: Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4698-1970 Alma Varieties Inc.Variétés Alma inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Armando Capcllo, agent, 8560 Brown Avenue, André Boucher, technician, 1470 Thierry Street, and Amerigo Capcllo, clerk, 1574 Rancourt Street, all three of LaSalle, for the following purposes: 6794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1070, 102' année, n° .',.9 Faire le commerce île toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Aima Varieties Inc.\u2014 Variétés Aima inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège sociul de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-l'i il lippe Bouchard.37391 4104-1970 Les appartements Plein Ciel liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, cpi'cn vertu de la première partie de lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 0c jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Camille Antaki, avocat, Alberto Salim Nadir, et Samira Koussa De Salim, ces deux derniers administrateurs, tous trois de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Les appartements Plein Ciel liée », avec un capital total de S40.000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 1000, rue Lawlor, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, coni]>agnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.37391-0 4336-1970 ArseiH¦' - Service Stations Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1 le jour de septembre 1970, constituant en corporation: Arsène Ohanian, garagiste, Rita Tamzarian, ménagère, épouse dudit Arsène Ohanian, tous deux de 5546, rue Earle, et Allan dayman, comptable, 7448, chemin Kingsley, npp.505, tous trois de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Exploiter des stations-service, bâtiments et garages et faire le commerce de véhicules, accessoires et pièces, sous le nom de « Arscne's Service Stations Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S10 chacune et 300 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Lc-siège social de la compagnie est 6710, chemin de la Côte Saint-Luc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391 3928-1970 Association d'entraide de Stc-Annc de Beaupré inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Luce Sicotte, Jacqueline Duguet, toutes deux de 8, Côte Ste-Annc, Sainte-Anne-dc-Beaupré, et Marie-Paule Lan- To deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Alma \\ arieties Inc.\u2014 Variétés Alma inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at Montreal judicial district of Montreal.Ls-Piiii.ippe BoucnARi), Deputy Minister of Financial Institut w,'-.Companies and Cooperatives.37391-0 41(11-1970 Les appartements Plein Ciel liée Notice is given that under Part I of thc Companies Act, letters patent, bearing dale die 0th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Camille Antaki, advocate, Alberto Salim Nadir, and Samira Koussa De Salim, the latter two administrators, all three of Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under thc name of \"Les appartements Plein Ciel Itée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 500 common shares of a nominal value of $10 each and 3,500 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at 1000, Lawlor Street, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-PlllLIPPE BoUCIIAItll.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.37391 4336-1970 Arsenc's Service Stations Lid.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 11th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Arsène Ohanian, garage owner, Rita Tamzarian, housewife, wife of the said Arsène Ohanian, hulh of 5546 Earle Street, and Allan dayman, accountant, 7448 Kingsley Road, Apt.505, all threeol Côte Saint-Luc, for the following purposes: To operate service stations, buildings and garages and deal in vehicles, and the accessories and parts, under the name of \"Arsenc's Service Stations Ltd.\", with a total capital slock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $10 each and 300 preferred shares ol a par value of S100 each.The head office of the company is at 6710 Côte St.Luc Road, Montreal, judicial dislrict of Montreal.J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.37391-0 3928-19ÎI Association d'entraide de Stc-Annc de Beaupré inc.Notice is given that under Part III of II* Companies Act, letters patent, bearing imtc.uj 18th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institution-.Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Luce Sicotte, .lacque-line Duguct, both of 8 Côte Stc-Annc, Sainte-Anne-dc-Beaupré, and Maric-Paule Langlois, w QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6795 glois.60, avenue Laurier, app.6, Québec, toutes trois secretaires, filles majeures, pour les objets suivants: Ailler à assurer le bon fonctionnement de toute oeuvre sociale, éducative et de formation morale, sous le nom de « Association d'entraide de Stc-Annc de Beaupré inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de S500.000.Le siège social de la corporation est à Saintc-Anne-'le-lleaupré, district judiciaire de Québec./.r sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37301-.3571-1970 Laurier Avenue, Apt.6, Québec, all three secretaries, spinsters of the full age of majority, for the following purposes: To foster the smooth operation of works of a social, educational and moral nature, under the name of \"Association d'entraide de Ste-Anne de Beaupré inc.\".The amount to which is limited thc value of the immovable property which may be owned or held by thc corporation is S500.000.The head office of the corporation is at Saintc-Annc-de-Beaupré, judicial district of Québec.J.-Albert Bouchard, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3571-1970 L'association des marchands de la place Lcvassctir inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions : Yves-J.Deniers, avocat, 55, de la Station, Dclson, Fernand Gagnon, marchand, 7749, Place Arundel, Jean-Claude Gralton, 8425, Châteauncuf, tous deux d'Anjou, Raymond Rochon, 9093, 13c Avenue, Montréal, Roger S l -Laurent, 6715, Henri Bourassa, Jacques Levnsscur, 59S0, boulevard Léger, app.4, tous deux de Montréal-Nord, tous quatre commerçants, et Michel Monastessc, fleuriste, 7590, Bonn.Saint-Léonard, pour les objets suivants: Étudier, promouvoir, protéger et développer de Imites manières les intérêts économiques, sociaux cl professionnels des membres, sous le nom de « L'Association des marchands de la place l.evasscur inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de 8100,000.Le siège social de la corporation est 5600, Henri liourassa est, Montréal, district judiciaire de Montréal, Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 4169-1970 L'association des marchands de la place Levasscur inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Yves-J.Dcmers, advocate, 55 de la Station, Delson, Fcrnand Gagnon, merchant, 7749 Place Arundel, Jean-Claude Gratton, 8425 Châteauncuf, both of Anjou, Raymond Rochon, 9093, 13th Avenue, Montreal, Roger St-Laurent, 6715 Henri Bourassa, Jacques Lcvasscur, 5980 Léger boulevard, Apt.4, both of Montreal-North, all four merchants, and Michel Monastessc, florist, 7590 Bonn, Saint-Léonard, for the following purposes: To study, promote, protect and develop in every way the economic, social and professional interests of its members, under the name of \"L'Association des marchands de la place Levasscur inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which may be owned or held by thc corporation is 8100,000.The head office of the corporation is at 5600 Henri Bourassa east, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4169-1970 Association (Hellénique) des parents Grccs-Orlbodoxcs de l'école Central Park Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Central Park School Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu (le la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Panagiotis Natos, 2911, avenue Rathwell, Thçmistoklis Stellatos, 809, avenue Provost, et Dimoslhenis Chryso-nie'is, 781, 30e Avenue, tous trois employés, de Lacliine, pour les objets suivants: Promouvoir la coopération entre parents, élèves cl professeurs de l'école Central Park, sous le nom de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Central Park \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of «'entrai Park School*.Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder et détenir la corporation est de $40,000.Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Central Park Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Central Park School Notice is given that under Part in of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Panagiotis Natos, 2911 Rathwell Avenue, Thçmistoklis Stellatos, 809 Provost Avenue, and Dimosthcnis Chryso-mclis, 781, 30th Avenue, all three employees, of Lachinc, for the following purposes: To promote cooperation between the parents, the pupils and the teachers, under the name of \"Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Central Park \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Central Park School\".The amount to which the value of the immoveable property wltich may be owned or held by the corporation is to be limited is $40,000. 6796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102e année, n\" 18 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.beht Gagnon.37391 4192-1970 Association (Hellénique) des parents Grccs-Orlhodoxcs de l'école Lachinc ltapids Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of l.uchinc Kapids School Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 0e jour d'octobre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: George Tachialis, graphiste, 555, 40e Avenue, Spiros Voutos, restaurateur, 515, 37e Avenue, tous deux de LaSallc, et Argirios Hliaras, cuisinier, 2S45, avenue Jacques-Hcrtel, Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir la coopération entre parents, élèves et professeurs de l'école Lnchine Rapids, sous le nom de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Lachinc Rapids \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Lachinc Rapids School ».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de S40.000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.bkkt Gagnon.37391 4352-1970 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Russell Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Russell School Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Constantinos Hountn-las, tricoteur, 8601, rue (\"hampagneur, app.2, Minas Cafedjis, mécanicien, 653, rue d'Anvers, et George Apostolopoulos, presscur, 8005, rue ('hampagneur, app.7, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir la coopération entre parents, élèves et professeurs de l'école Russell, sous le nom de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Russell \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Russell School ».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de S40.000.Le siège social de lu corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Ai.beht Gagnon.37391 4193-1970 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orlhodoxes de l'école Sinclair Laird Creek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Sinclair Laird The head office of the corporation is al Mont-real, judicial district of Montreal.J.-Albèrt Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives 37391-0 4192-1970 Association (Hellénique) des parents Crées-Orthodoxes de l'école Lachinc Kapids Greek Orthodox (Hellenic) Associa lion of Parents of Lachinc ltapids School Notice is given that under Part III of |hc Companies Act, letters patent, bearing dale the 6th day of October, 1970, have been issued Ky the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative to incorporate a corporation without share capital: George Tachialis.commercial artist, 555, 40th Avenue, Spires Voutos, restaurateur, 515, 37th Avenue, both of l.aSalle, and Argirios Hliaras, cook, 2845 Jacques Henri Avenue, Montreal, for the following purposes: To promote cooperation between the parents, the pupils and thc teachers, under the name of \"Association (Hellénique) des parents (irccs-Orthodoxes de l'école Lachinc Rapids- (ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Lachinc Rapids School\".Thc amount to which thc value of thc immoveable property which may be owned or held by thc corporation is to be limited is S40.000.The head office of thc corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Ai.beht Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 \u2022 4352-1970 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Russell Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Russell School Notice is given that under Pari III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without, share capital: Constantinos lloiin-talas, knitter, 8601 Champagneur Street, Apt.2, Minas Cafedjis, mechanic, 653 d'Anvers SI reel, and George Apostolopoulos.presser, 8605 ('hampagneur Street, Apt.7, nil three of Moid real, for the following purposes: To promote cooperation between the parents, the pupils and the teachers, under the name of \"Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Russell \u2014 (ireek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Russell School\".Thc amount to which the value of the immoveable properly which may be owned or held by thc corporation is to be limited is $40,001'.The head office of thc corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai' 'es.37391-0 4193-1970 Association (Hellénique) des parents Grecs?Orthodoxes de l'école Sinclair Laird Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Sinclair Laird Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dob tlie Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6797 dp lu troisième partie de la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: John Floras, barbier, 8531, a venue Wiseman, app.2, Peter Voyatzakis, entrepreneur, 930, d'Anvers, et Andreas Kcfalli-nos, opérateur de buanderie, S518, Wiseman, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Promouvoir la coopération entre parents, élèves cl professeurs de l'école Sinclair Laird, sous le 1)0111 de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Sinclair Laird\u2014\u2022 (inek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Sinclair Laird School ».I.e montant auquel doit se limiter la valeur îles biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de $40,000.I.e siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.I.e sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeut Gagnon.37391 4195-1970 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: John Floras, barber, 8531 Wiseman Avenue, Apt.2, Peter Voyatzakis, contractor, 930 d'Anvers, and Andreas Kefalli-nos, laundry operator, S518 Wiseman, all three of Montreal, for the following purposes: To promote cooperation between the parents, the pupils and the teachers, under the name of \"Association (Hellénique) des parents Grecs-Orlhodoxcs de l'école Sinclair Laird \u2014(ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Sinclair Laird School\".Thc amount to which the value of thc immoveable property which may be owned or held by thc corporation is to be limited is $40,000.The head office of thc corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Ai.nionT Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4195-1970 Association des Psyoliotechniciciis du Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean Frappicr, Pierre Salvail.tous deux avocats, et Cécile Peloquin, secrétaire, fille majeure, tous trois de 70, du Roi, Sorel, pour les objets suivants: Promouvoir la formation professionnelle des membres, sous le nom de « Association des Psy-chotccliniciens du Québec».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de $100,000.Le siège social de la corporation est 230, rue Ilenri-lîourassa est, suite 5, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37301 -o 4030-1970 Association des Psycholeehniciens du Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jean Frappicr, Pierre Salvail, both advocates, and Cécile Peloquin, secretary, spinster of the full age of majority, all three of 70 du Roi, Sorel, for the following purposes: To promote thc professional formation of its members, under the name of \"Association des Psycholechniciens du Québec\".To amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is S100,000.The head office of the corporation is at 230 Henri-Bourassa Street East, Suite 5, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Ai.bert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4030-1970 Association (Hellénique) des parents Grecs Orthodoxes de l'école Bedford (\u2022reck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Bedford School Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu 'le la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Constantina Lambadas, opérateur de machine, 32S5, rue Barclay, app.11, George Constantinidis, nettoyeur, 2655, rue Barclay, app.10, et Charalabos Xenox, opérateur, 3355, rue Barclay, app.10, tous trois de Montréal, Pour les objets suivants: Favoriser la coopération entre les parents, les élèves et les professeurs, sous le nom de « Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Bedford \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Bedford School\"* Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Bedford Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Bedford School Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital : Constantina Lambadas, machine operator, 3285 Barclay Street, Apt.11, George Constantinidis, cleaner, 2655 Barclay Street, Apt.10, and Charalabos Xenox, operator, 3355 Barclay Street, Apt.10, all three of Montreal, for the following purposes: To promote cooperation between the parents, the pupils and the teachers, under thc name of \"Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Bedford \u2014 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Bedford School\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold or possess, is to be limited, is $40,000.Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut posséder ou détenir est de $40,000. 6798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° £8 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des instihdions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391 4202-1970 L'Association des scouts de l'Immaculéc-Conception de Grnnby inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel St-Martin, comptable, 687, Denison ouest, Aurélius Laro-chcllc, dessinateur, 512, Denison ouest, et Richard Goulet, asureur-vie, 301, Dufferin, tous trois de Granby, pour les objets suivants: Venir en aide aux membres et aux mouvements scouts de la paroisse Immaculée-Conception de Granby, sous le nom de « L'Association des scouts de lTmmaculée-Conccplion de Granby inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de SI 00,000.Le siège social de la corporation est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sons-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391-0 4083-1970 Auteuil sport inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour de juillet 1970, constituant en corporation: Robert Trépanier, jardinier, Denise Paradis, ménagère, épouse dudit Robert Trépanier, tous deux de 33, boulevard Bellerose, Marc Desjardins, garagiste, et Céline Gauthier, ménagère, épouse dudit Marc Desjardins, ces deux derniers de 115, rue Scaron, tous quatre de Laval, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'articles de sports motorisés ou non, de moteurs, machines de sports, leurs parties et accessoires, sous le nom de < Auteuil sport inc.», avec un capital total de 875,000, divisé en 15,000 actions ordinaires de SI chacune et en 6,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 5685, boulevard des Laurentides, Laval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlIlUPPE bouciiabd.37391-0 3161-1970 Autos Paul Audet liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Jean-Paul Audet, mécanicien, Jacqueline Chabot, ménagère, épouse dudit Jean-Paul Audet, tous deux de 7745, Paul Comtois, Charlesbourg, et Thérèse Abran, secrétaire-comptable, épouse The head office of thc corporation is at Mont, real, judicial district of Montreal.J.-Albeht Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives 37391-0 '1202-1070 L'Association des scouts de rimniacuIéc-Conccption de Granby in(.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 18th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Com.panics and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Marcel St-Martin, accountant, 687 Denison west, Aurélius I.nro-chelle, draughtsman, 512 Denison west, and Richard Goulct, life insurance agent, 301 Dufferin, all three of Granby, for thc following purposes: To help the members and encourage the activities of the boy-scouts of thc parish of thc Immaculate Conception of Granby, under Hie mime of \"L'Association des scouts de l'Immaculée-Conception de Granby inc.\".Thc amount to which is limited the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is 8100,000.Thc head office of thc corporation is at Granby, judicial district of Bedford.J.-Albeht Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopéraiiits.37391 4OMÎ-1970 Auteuil sport inc.Notice is given that under Part I of (lie Companies Act, letters patent, bearing dale the 20th day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Trépanier, gardener, Denise Paradis, Housewife, wife of said Robert Trépanier, both of 33 Bellerose Boulevard, Marc Dcsjardins, garage keeper, and Céline Gauthier, housewife, wife of said Marc Desjardins, the latter two of 115 Scaron Street, all four of Laval, for the following purposes: To manufacture and deal in sports till ides, motorized or otherwise, motors, sports cars, their parts and accessories, under the name of \"Auteuil sport inc.\", with a total capital stock of 875,000, divided into 15,000 common shares of 81 each and into 6,000 preferred shares of 810 each.The head office of thc company is al âliSâ Laurentide Boulevard, Laval, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe bouchahi), Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 31G1-1H70 Autos I'aul Audct lice Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 24th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating : -lean-Paul Audet, mechanic, Jacqueline Chabot, housewife, wife of said Jean-Paul Audet, both of \u2022 Î4a Paul Comtois, Charlesbourg, and Thérèse Abran, accountant-secretary, wife of Gerry Lorangcr.S19 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2S, 1970, Vol.102, No.1,8 0799 île Gerry Lornnger, 819, des Saules est, Quebec, |Hiur les objets suivants: l'aire le commerce, la réparation et l'entretien île véhicules automobiles de toutes espèces, sous h- nom de « Autos Paul Audet liée », avec un capital total de S40.000, divisé en 300 actions ordinaires de $100 chacune et en 100 actions pri-vilégiécs de S100 chacune.I .!¦ siège social de la compagnie est à Cap-Santé, district judiciaire de Québec./.«¦ nous-minitlre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiimppe Bouchard.37391-0 4220-1970 des Saules East, Québec, for the following purposes: To deal in, repair and maintain motor vehicles of all kinds, under the name of \"Autos Paul Audet liée\", with a total capital slock of S40.000, divided into 300 common shares of $100 each and 100 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Cap-Santé, judicial district of Québec.Ls-Piiilii'pe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4220-1970 Les Auxiliaires de l'hôpital du lluiit-Kiclielicu inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'octobre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Charlotte Dcsranleau, épouse de Real Désourdy, 432, Latour, Pierrette Dcland, épouse de Gcorges-A.LeSieur, 340, l.elieaii.toutes deux ménagères, Suzanne Gau-dreau, institutrice, fille majeure, S3, St-Charles, Françoise Comcau, infirmière, épouse de Eugène l.usiiicr, 190, boulevard Gouin, et Josée Rain-villc, secrétaire, épouse de Norman F.Ménard, 304, St-Laurcnt, toutes de Saint-Jean, pour les olijeU suivants: Servir les objectifs généraux de l'hôpital du Haut-Richelieu inc., soit plus particulièrement, renseignement des sciences médicales et paramédicales, la recherche et le soin des malades, sous le nom de « Les Auxiliaires de l'hôpital du Haut-Richelieu inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de $100,000.Le siège social de la coriioration est Hôpital du Haul Richelieu inc., Saint-Jean, district judiciaire d'iberville.U sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiiuppe bouchard.37391-0 1039-1970 Les Auxiliaires de l'hôpital du Haut-Kicliclicu inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation: without share capital: Charlotte Desran-Icau, wife of Real Désourdy, 432 Latour, Pierrette Deland, wife of Gcorgcs-A.LcSicur, 340 Lcbeau, both housewives, Suzanne Gaudreau, teacher, spinster of the full age of majority, 83 St-Charles, Françoise Comcau, nurse, wife of Eugène Lasnier, 190 Gouin Boulevard, and Josée Rainville, secretary, wife of Norman F.Ménard, 304 St-Laurcnt, all of Saint-John's, for the following purposes: To serve general purposes of thc hospital of Haut-Richclicu inc., namely and more particularly, the teaching of medical and para-medical sciences, the research and the care of sick persons, under the name of \"Les Auxiliaires de l'hôpital du Haut-Richelieu inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that the corporation may acquire and hold is S100.000.The head office of the corporation is at Hospital of Haut-Richelieu inc., Saint-John's, judicial district of Iberville.Ls-Piiilippe Isouchakd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 1039-1970 Rargcllctli Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnie-, et.coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi tics compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Bruno Bargelletti, dessinateur, 10430, avenue Laurcntidc, Montréal-Nord, Moses H.Myerson, avocat, 5235, chemin Côte Saint-Luc, cl Bessie Solomon, secrétaire, veuve d'Alex Solomon, 5550, avenue Trent, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: rosser des contrats de charjicnlcrie, transformation et amélioration dons les structures existantes, sous le nom de « Bargelletti Ltd.», avec \"» capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est 10430, avenue Laurcntidc, Montréal-Nord, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, \u201e_ Ls-Philippe Bouchard.3,39l 4118-1970 Bargelletti Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bruno Bargelletti, draftsman, 10430 Laurcntidc Avenue, Montreal North, Moses H.Myerson, attorney, 5235 Cote St.Luc Road, and Bessie Solomon, secretary, widow of Alex Solomon, 5550 Trent Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To operate a contracting business for carpentry, and for modification and improvements in existing structures, under thc name of \"Bargelletti Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 common shares of S100 each.Thc head office of the company is at 10430 Laurcntidc Avenue, Montreal North, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4118-1970 6800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÊIIEC, 28 novembre 1070, 102' année, n\" 1,8 J.C.Beliveau liée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes en date du 17c jour de septembre 1970, constituant en corporation : Richard Béliveau, professeur, 11, rue Fiché, Jacques Béliveau, technicien, 300, rue Olivier, tous deux de Victoriavillc, et lluguctte Gardner, coiffeuse, épouse de Jean-Claude Béliveau, 65, rue Landry, Norbcrtville, pour les objets suivants: ï'airc le commerce cl la livraison d'huile à chauffage, gnzoline, huile diesel, huile à moteur et tous autres produits dérivés du pétrole, sous le nom de « J.C.Béliveau Héc », avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 05, nie Landry, Norbcrtville, district judiciaire d'Artha-baska.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 4044-1970 Michael Berk Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Louis Bercovitch, 366, rue Vivian, Mont-Royal, Michael Bercovitch, tous deux hommes d'affaires, et Maxine Ncidit/., ménagère, épouse dudit Michael Bercovitch, ces deux derniers du 413, Davignon Drive, Dollard-des-Ormcaux, pour les objets suivants: S'établir conseillers cl experts auprès de l'administration et des directeurs d'entreprises commerciales ou d'établissements industriels, sous le nom de ' Michael Berk Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10.000 actions ordinaires de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 413, Davignon Drive, Dollard-des-Ormcaux, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 4000-1970 Ernest Bcrnicr inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coo|>érativcs donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en dale du 10e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Ernest Bcrnicr, voyageur, Elizabeth Bcrnicr, secrétaire, épouse dudit Ernest Bernicr, tous deux de 20, Rogers Lane, et Gisèle Adam, ménagère, épouse de Jacques Adam, 30, Rogers Lane, tous trois tie Drummondville, j>our les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de tricots, textiles, ainsi que leurs produits et sous-produits, sous le nom de « Ernest Bernicr inc.», avec un cnpital total de 8100,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune, 100 actions privilégiées classe « A » d'une valeur nominale de S10 chacune et en 4,900 actions privilégiées classe « B » d'une valeur nominale de $10 chacune.J.C.Béliveau liée Notice is given that under l'art I ni tlic Companies Act, letters patent, bearing dale thc 17th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com-panics and Cooperatives, incorporating: Richard Béliveau, professor, 11 Fiché street, Jacques Béliveau, technician, 300 Olivier Street, both of Victoriavillc, and Huguettc Gardner, hairdn sscr, wife of Jean-Claude Béliveau, 65 Landry Street, Norbcrtville, for the following purposes: To cany on a business in and to deliver healing oil, gasoline, diesel oil, motor oil and all the other by products of petroleum, under thc name of \"J.C.Béliveau Héc\", with a total capital slock of $40,000, divided into 2,000 common -hares of S10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.Thc head office of the company is at 65 Landry Street, Norbcrtville, judicial district of Arlha-baska.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.37391 4044-1970 Michael Berk Inc.Notice is given that under Fart I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Louis Bercovitch, 300 Vivian Street, Mount Royal, Michael Bercovitch, both businessmen, anil Maxine Neidilz, housewife, wife of the said Michael Bercovitch, thc latter two of 413 Davignon Drive, DolIard-dcs-Ormcaux, for the following purposes: To act as consultants and advisers in general to the management and executives of any commercial enterprise or industrial organization, under the name of \"Michael Berk Inc.\".with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 3,00(1 preferred shares of $10 each.Thc head office of the company is at 413 Davignon Drive, Dollard-des-Ormcaux, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperative*.37301-o 4000-1970 Ernest Bernicr inc.Notice is given that under l'arl I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing dale Ihe 10th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com?naiiies and Cooperatives, incorporating: Ernest Bernicr, traveller, Elizabeth Bernicr, secretary, wife of said Ernest Bernicr, both of 20 Rogers Lane, and Gisèle Adam, housewife, wife of Jacques Adam, 30 Rogers Lane, all three of Drummondville, for thc following purposes: To manufacture and deal in knitted fabrics, woven material, as well as their product\" and by-products, under the name of \"Ernest Bcniiei inc.\", with a total capital stock of $ 10(l, de $100 chacune et en 2,000 actions privilégiées classe « B » de S25 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.If sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 4207-1970 Centre des loisirs de Scotstown Scotstown Recreation Center I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Réal Boulanger, mécanicien.Alfred Lizottc, maître de poste, Fërnand Pelletier, technicien, et Lionel Langlois, soudeur, tous quatre de Scotstown, pour les objets suivants: \u2022 {\u2022'organisation des loisirs, sous le nom de c Centre des loisirs de Scotstown \u2014 Scotstown Recreation Center ».I.e montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $10,000.I.e siège social de la corporation est à Scots-town, district judiciaire de Saint-François.I.e sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.bert Gagnon.37391-0 5631-1968 Léo Chaurct construction inc.0803 Ncssie Borland, 1850 Lincoln, Lise Rozon, 6405 Laurcndeau, and Lucie Trudeau, 7175 Christophe Colomb, the latter four secretaries, spinsters, the latter five of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in ores, minerals and chemicals of any kind, under the name of \"Canadian Tiron Chemical Corporation\", with a capital stock divided into 40,000 shares without nominal or par value.Thc head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 3899-1970 Centre de gestion polyvalent du Québec (C.G.P.Q.) liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: René Myrand, 1572 Cardinal-Villeneuve, Québec, André Homel, 2, 42nd Street, Val Saint-Michel, Yves Tremblay, 7025, 7th Avenue East, all three technicians, André Bélanger, representative, 880, 71st Street East, both of Charlesbourg, (iilles-T.Tremblay, 3355 Queen Mary Road, Montreal, and Paul Gendron, 630 Mélèzes, Trois-Rivières, the latter two administrators, for thc following purposes: To carry on business as an investment company, under the name of \"Centre de gestion polyvalent du Québec (C.G.P.Q.) ltéc\", with a total capital stock of $200,000, divided into 2,000 common shares of $5 each, 1,400 class \"A\" preferred shares of S100 each and into 2,000 class \"B\" preferred shares of $25 each.Thc head office of thc company is at Québec judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4207-1970 Centre des loisirs de Scotstown Scotstown Recreation Center Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Réal Boulanger, mechanic, Alfred Lizottc, postmaster, Fcrnand Pelletier, technician, and Lionel Langlois, welder, all four of Scotstown, for thc following purposes: To organize leisure activities, under thc name of \"Centre des loisirs de Scotstown \u2014 Scotstown Recreation Center\".The amount to which is limited the value of the immovable properly which may be owned or held by the corporation is $16,000.Thc head office of the corporation is at Scots-town, judicial district of Saint-François.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 5631-1968 Léo Chaurct construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu GS04 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,S de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentés, en date du 15c jour de septembre 1970, constituant, en corporation: J.-Rcné Paiement, avocat, 112, 9e Rue, Roxboro, Léo Chauret, homme d'affaires, 4534, chemin des Sources, Dollard-des-Ormcaux, et Céline Contant, secrétaire, fille majeure, 5000, Pie IX, Montréal, pour les objets suivants: Paire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Léo Chauret construction inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 4534, Chemin des Sources, Dollard-des-Ormcaux, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-I'nii.ii'i'i: Houciiaud.37391-0 .3972-1970 La chifïbiuicric L.G.lice Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Salomon G.Dalian, Levy Ohnana, tous deux administrateurs, du 3S42, avenue Kent, et David I, Schatia, avocat, 7025, chemin ('lover, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Tenir un ou des ateliers et boutiques de robes, sous le nom de «La chiffonnerie L.G.liée», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 3905-1970 Ciné-parc des 1 Chemins inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 23c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Mireille Levesquc, épouse de Michel Mar-tincau, 31, 33e Rue, Val Saint-Michel, Micheline Lapoinle, épouse de André Plante, 130, avenue Lamontagne, Québec, et Lisette Heaulicu, fille majeure, 3, rue St-Mauricc, Lorctleville, toutes trois secrétaires, pour les objets suivants: Exploiter un ou plusieurs ciné-parcs, sous le nom de « Ciné-parc des 4 Chemins inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 3,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 1,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 771, St-Joseph est, suite 309, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre associé des institutions fina7icières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 4164-1970 Club d'aviation Vénus inc.the 15th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institution-.Com-panics and Cooperatives, incorporating: ,1.|{Cne Paiement, advocate, 112, 9th Street, Rnxhoro Léo Chauret, businessman, 4534 des Sources Road, Dollard-des-Ormcaux, and Céline Con.tant, secretary, spinster of the full age of majority, 5060 Pie IX, Montreal, for thc following purposes: To carry on business as general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Léo Chauret construction inc.\", with a total capital stock of 810,000, divided into 10,000 common shares of si each and into 30,000 preferred shares of SI each.Thc head office of the company is at 4534 des Sources Road, Dollard-des-Ormcaux, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 39721970 La chiffonnerie L.G.liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 101b day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Salomon G.Dalian, Levy Ohnana, both executives, of 3S42 Kent Avenue, and David I.Schatia.advocate, 7025 ('lover Road, all three of Montreal, for the following purposes: To operate a dress shop or shops an boutiques, under the name of \"La chiffonnerie L.G.liée\", with a total capital stock of S40,00(), divided into 2,000 common shares of §10 each anil '-'.1)00 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.3739 l-o 3965-1970 Ciné-parc des 1 Chemins inc.Notice is given that under Tart I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mireille Lcvcsque, wife of Michel Martineau, 31, 33nl Street, Val Saint-Michel, Micheline Lapoinle, wife of André Plante, 130 Lamontagne avenue, and Lisette Beaulicu, spinster of thc full age of majority, 3 St-Maurice Street, Loretteville, all three secretaries, for the following purposes: To operate one or more outdoor cinemas, under the name of \"Ciné-parc des 4 Chemins inc.\", with a total capital stock of $40.900, divided into 3,000 common shares of a nominal value of $10 each and 1,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at 7/1 St.Joseph East, suite 309, Québec, judicial district of Québec.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.37391 4164-1970 Club d'aviation Vénus inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu Notice is given that under Part III of Ihe Companies Act, letters patent, bearing date the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2S, 1970, Vol.102, No.18 0S05 de la troisième purlic tie la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lGc jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Roland l.avignc, électronicien, Saintc-Gertrude, Gaétan Grenier, génial, 3250, rue De Calais, Trois-Rivières-Ouest, Armand Martin, rentier, 1040, rue Sle-Gcnevièvc, cl l'util Bouchard, électricien, 3314, nie Provcn-clier, ces deux derniers de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Promouvoir l'aviation, sous le nom de « Club il'a via lion Vénus inc.».I.r montant auquel est limitée la valeur des liions i.îobiliers que peut acquérir et posséder là corporation est de S100.000.Le -iège social de la corporation est à Trois-Rivicrcs-Ouest, district judiciaire de Trois-Rivières.le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.37301 o 4042-1970 lOth day of Spetcnibcr, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Roland Lavignc, électronicien, Sainte-Gerlrudc, Gaétan Grenier, manager, 3250 De Calais Street, Trois-Rivièrcs-West, Armand Martin, annuitant, 1040 Stc-Gencviève and Paul Bouchard, electrician, 3314 Provenchcr Street, the latter two of Trois-Rivières, for the following purposes: To promote aviation, under the name of \"Club d'aviation Vénus inc.\".The amount to which is limited thc value of thc immovable property that the corporation may acquire and hold is S100.000.The head oflice of thc corporation is at Trois-Rivières-West, judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4042-1970 Club de golf dc Murdochvillc inc.M m dm h\\il le Golf Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 20c jour d'août 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Pierre Boudrcault, Gilbert Sau-rinl.Ions deux ingénieurs, et Ovide Le lion! illier, planificateur, tous trois de Murdochvillc, pour les objets suivants: Promouvoir la pratique du golf, sous le nom dc < Club de golf de Murdochvillc inc.\u2014 Murdochvillc (mlf Club Inc.».Le montant auquel est limitée lu valeur des liions immobiliers (pic peut acquérir et posséder In corporal ion, est de 180,000.Le >iègc social dc In corporation est à Murdochvillc.district judiciaire dc Gaspé.u sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 3 653-1970 Clul» dc golf de Murdochvillc inc.Murdochvillc Golf Club Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of August, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without, share capital: Pierre Boudrcault, Gilbert Sauriol, both engineers, und Ovide Le Boutillicr, planner, all three of Murdochvillc, for the following purposes: To promote golf sport, under the name of \"Club de Golf de Murdochville inc.\u2014 Murdochvillc Golf Club Inc.\".The amount to which is limited thc value of the immovable property that thc corporation may acquire and hold is 8S0.000.The head office of the cor|k>rulion is at Murdochvillc, judicial district of Gaspé.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives.37391 3653-1970 Miib Molo-Ncigc 1 I'linqiii lin inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu \u2022le la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de septembre 1970, constituant en corporation «ans capital-actions: Guy Viens, commis, Hurolil Pelletier, cuvistc, Benoit Charest, bûcheron, Jacques Légaré, Jean Huard, Jean-Marc Gagnon.cl Serge Légaré, ces quatre derniers journalier, tous de Franquelin, pour les objets suivants: Exploiter un club sportif et promouvoir en particulier le sport de la moto-neige, sous le nom île « Club Moto-Neige Franquelin inc.».Le montant auquel est limitée In valeur des neiis immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc §20,000.Le siège social dc la corporation est à Franquelin.¦listrict judiciaire de Hauterive./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.«391-0 4214-1970 Club Moto-Neige Franquelin inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 28th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incori>oratc a corporation without share capital: Guy Viens, clerk, Harold Pelletier, pot-man, Benoit Charest, lumberer, Jacques Légaré, Jean Huard, Jean-Marc Gagnon, and Serge Légaré, the latter four labourers, all of Franquelin, for thc following purposes: To ojieratc u sport club and particularly promote snowmobile sport, under the name of \"Club Moto-Neige Franquelin inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property that thc corporation may acquire and hold is S20.000.The head office of thc cor|x>ration is at Franquelin, judicial district of Hauterivc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4214-1970 G80G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n\" AS Le club moto-neige les Multicolores «le St-Césairc inc.Le ministre des institutions financières! compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 15e jour dc septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard Denicourt, opérateur, Jean-Denis Côté, gérant, et Joseph Boucher, éboucur, tous trois de Saint-Césaire, pour les objets suivants: Promouvoir les sports en général et, en particulier, le sport de l'aulo-ncigc, sous le nom de « Le club moto-neige les Multicolores de St-Césairc inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder lu corporation, est dc 820,000.Le siège social de la corporation est à Saint-Césaire, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.7.c sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-ALBERT GA(iNON*.3739 l-o 2S35-1970 Le club moto-neige les Multicolores de St-Césairc inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the lath day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Gerard Denicourt, operator, Jean-Denis Côté, manager, and Joseph Boucher, road-sweeper, all three of Saint-Césaire, for the following purposes: To promote sports in general and, in particular, the sport of snowmobiling, under the name of \"Le club moto-neige les Multicolores dc Si-Ci-, saire inc.\".Thc amount to which is limited the value of Ihe immovable properly which may be owned or held by thc corporation is S20.000.Thc head olficc of the corporation is al Saint-Césaire, judicial district of Saint-Hyacinthe.J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 2835-1970 (lui, social dc Iticlnnoiid liidimniid Social Club Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de juillet 1970.constituant en corporation sans capital-actions: Paul Dclancy, courtier d'assurance, André Grégoire, notaire, tous deux de 14S, rue Principale nord, et Claude Brouilletle, gérant d'usine, -179, Brouillette, tous trois dc Richmond, pour les objets suivants: Etablir et exploiter un club social, sous le nom de « Club social de Richmond \u2014 Richmond Social Club ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 850,000.Le siège social de la corporation est à Richmond, district judiciaire de Saint-François.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe BoraïAitD.37391-0 2913-1970 Club social dc Richmond Richmond Social Club Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 23rd day of July, 1970.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incor|x>ratc a corporation without share capital: Paul Dclancy, insurance broker, André Grégoire, notary, both of 148 Main Street, North, and Claude Brouillette.factory manager, 479 Brouillette, all three of Richmond, for the following purposes: To establish and operate a social club, under the name of \"Club social dc Richmond - Richmond Social Club\".Thc amount to which is limited the value of Ihe immovable property that the corporation may acquire and hold is 850,000.Tile head office of the corporation is at Richmond, judicial district of Saint-François.Ls-Piiii.ii'pe Bourn Aim.Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.37391 2913-1970 Club social dc Slc-Murie inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24c jour de septembre 1970, constituant en corpor-tion sans capital-actions: Claude St-Onge, mécanicien, Conrad Boivin, journalier, et Lise Martel, professeur, épouse dudit Conrad Boivin, tous trois de Saintc-Maric-dc-Blandford, pour les objets suivants: Etablir et administrer un club social, sous le nom dc « Club social dc Sic-Marie inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que jieut acquérir et posséder la corporation, est dc S200.000.Le siège social de la corporation est à Saintc-Marie-de-Blandford, district judiciaire dc Ni-colct.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 3940-1970 Club social de Slc-Maric inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing «Iule Ihe 24th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Claude St-Onge, mechanic, Conrad Boivin, labourer, ami Lise Martel, teacher, wife of the said Conrad Boivin.all three of Sainte-Muric-de-Blnndford, for the following purposes: To set up and manage a social club, under the name of \"Club social dc Stc-Marie inc.\".Thc amount to which is limited the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is $200,000.Thc head office of thc corporation is at Saintc-Maric-de-Blandford, judicial district of Nicolct J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopcrali\"-37391 3940-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, J070, Vol.102, No.18 GS07 I.a compagnie «le gestion île la Malapédia ltéc Le ministre tics institutions financières, compagnie- et coopératives donne avis, qu'en vertu île lu première pnrlic dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 17e jour ili' septembre 1970, constituant en corporation: Clément Richard, avocat, 3255, dc la Paix, Sainl' l'\"oy, Jean-Claude Simard, étudiant, 489, chemin Slc-Foy, Québec, et Monique Gagnon, secrétaire, fille majeure, 2590, l'laza, Sillcry, pour li - objets suivants: l'aiii nlfaires comme coni|iagnic dc portefeuille holding), sous le nom dc « La compagnie ucgestion de la Matapédiu liée », avec un capital total de $300,000, «livisé en 3,000 actions ordinaires de $100 chacune.|.e siège social dc la compagnie est à Causops-oil.district judiciaire de Rimouski.he sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 4094-1970 La compagnie de gestion dc lu Malapédia Héc Notice is given that under Part I of thc Companies Act, letters patent, bearing dale the 17th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Clément Richard, advocate, 3255 de la Paix, St.Foy, Jean-Claude Simard, student, 489 St.Foy road, Québec, and Monique Gagnon, secretary, spinster of the full age of majority, 2590 Plaza, Sillcry, for the following purposes: To do business as a holding company, under the name of \"La compagnie de gestion de la Malapédia liée\", with a total capital slock of 8300,000, divided inlo 3,000 common shares of S100 each.Thc head office of the company is at Causaps-cal, judicial district of Rimouski.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4094-1970 Complex Chemicals (Eastern) Ltd.Li- produits chimiques Complexes (dc 1'F.st) ltéc l.c ministre des institutions financières, compagnie- el coopératives donne avis, qu'en vertu Je la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de septembre 1970, constituant en corporation: David 11.Sohmcr, 5501, Adalbert, Côte Saint-Luc, Jacob Woloshcn, 2105, Lincoln, tous deux avocats, Hrcnda Mulviliill, épouse de Larry Miilvihill, 11955, Lachapelle, et Antonina Cuc-chiara.lillc majeure, 9150, 7e Avenue, ces deux dernières secrétaires, ces trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de produits chimiques de toutes sortes, sous le nom dc « Complex Chemicals (Eastern) Ltd.\u2014 Les produits chimiques t oiuplexcs (de l'Est) liée », avec un capitul total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires île SI chacune et 3,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le -lege social dc la compagnie est 500 ouest, me Sauvé, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Usait*-mini sire des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391 4076-1970 Complex Chemicals (Eastern) Ltd.Les produits chimiques Complexes (dc l'Est) liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David H.Sohmer, 5501 Adalbert, Côte Saint-Luc, Jacob, Woloshcn, 2105 Lincoln, both advocates, Hrcnda Mulvihill, wife of Lurry Mulvihill, 11955 Lachapelle, and Antonina Cucchiara, spinster, 9150, 7th Avenue, the latter two secretaries, the latter three of Montreal, for the following purposes: To manufacture und ileal in chemicals products of all kinds, under the name of \"Complex Chemicals (Eastern) Ltd.\u2014 Les produits chimiques Complexes («le l'Est) ltée\", with n total capital stock of 810,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 500 Sauvé Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4076-1970 La conciergerie Paul inc.Le ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes en date du 23e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Paul Companies Act, letters patent, bearing dale tl* QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Novembre 28, 1070, Vol.102, No.M8 0S09 île la première partie de la Loi des compagnies, j| a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour dc juillet 1970, constituant en corporation : Mil Murger, administrateur, Shirley Bercovitch, fyxnisc dudit Mcl Burger, tous deux du 2380, \\aulcl, Suint-Laurent, et Marion Simon, épouse île Maxwell Gordon, 406, avenue Letlibridgc, Mniii-lloyal, ces deux dernières ménagères, pour les objets suivants: S'établir entrepreneurs et constructeurs, sous le m un de « Construction Val des Arbres ltéc », avec un capital total dc $100,000, divisé en 400 acii.irdinaîres de $100 chacune et 600 actions privilégiées dc $100 chacune.I.e siège social de la compagnie est à Place du Canada, bureau 995, Montréal, district judiciaire île Montréal./.c sous-minislre associé des institution» financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.bkht Gagnon.37301 3217-1970 23rd day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mcl Burger, executive, Shirley Bercovitch, wife of the said Mel Burger, both of 2380 Xante), Saint-Laurent, and Marion Simon, wife of Maxwell Gordon, 406 I.ethbridge Avenue, Mount Royal, the latter two housewives, for the following purposes: To carry on business as contractors und builders, under thc name of \"Construction Val des Arbres ltéc\", with a total capital stock of $100,000 divided into 400 common shares of $100 each and 600 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Place du Canada, Room 995, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albebt Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 3217-1970 l.a corporation des maîtres-démolisseurs du Québec inc.Québec Corporation of Mastor-Dcmolishcrs Inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coo'iératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Bernard Lortic, 160, Kinchley Road, David Metrick, 4555, Bonavista, cl Henri l'nnzini, 2479, Jette, tous trois industriels, de Montréal, pour les objets suivants: Défendre, protéger, promouvoir par tous les moyens possibles les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres, sous le nom de « La corporation des maitrcs-démolis-ncurs du Québec inc.\u2014 Québec Corporation of Miisicr-Dcniolishers Inc.».I.e montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est de $50,000.I.e siège social dc la corjioration est à Montréal, ilislriel judiciaire de Montréal./.,\u2022 sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.bkut Gagnon.37391-0 3984-1970 La corporation des maîtres-démolisseurs du Québec inc.Québec Corporation of Maslcr-Dcmolishcrs Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date thc 14th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Finuncial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corjxim-tion without share capital: Bernard I.ortie, 160 Finchley Road, David Metrick, 4555 Bonavista, and Henri Panzini, 2479 Jette, all three industrialists, of Montreal, for the following purposes: To uphold, protect and promote in every way possible the economic, social and professional interests of the members, under thc name of \"La corporation des maîtres-démolisseurs du Québec inc.\u2014 Québec Corporation of Master-Demoli-shers Inc.\".The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation can acquire or possess is $50,000.The head office of the coi-poration is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37291 3984-1970 l.a Corporation du Festival d'automne de Rimouski inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la troisième partie dc la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Marc Allard, représentant d'affaires, Gabriel Dionnc, contrôleur, Christian Girard, Claude Picard, tous deux gérants de service, Guy Hins, homme d'affaires, Lucien Labrecque, gérant-adjoint, Thomas-Louis Simurd, Jean Thisdel, tous deux fonctionnaires, H I.André Bellavance, industriel; tous de Rimouski, pour les objets suivants: Promouvoir et développer tous genres d'activités touristiques, récréatives, sportives, culturelles cl sociales, sous le nom dc « La Corporation du Festival d'automne de Rimouski inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut ac-«liiérir et posséder est dc $250,000.La Corporation du Festival d'automne dc Rimouski inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a coloration without share capital: Marc Allard, business representative, Gabriel Dionnc, supervisor, Christian Girard, Claude Picard, both branch managers, Guy Hins, businessman, Lucien Labrecque, assistant manager, Thomas-Louis Si-maril, Jean Thisdcl, both civil servants, and J.-André Bellavance, industrialist, all of Rimouski, for the following purposes: To promote and develop all kinds of tourist, recreational, athletic, cultural and social activities, under the name of \"La Corporation du Festival d'automne de Rimouski inc.\".The amount to which the value of the real estate which the corporation can acquire of possess is $250,000. 0810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2S novembre 1970, 102' minée, n\" AS Le siège social de la corporation est à Rimouski, district judiciaire dc Rimouski.Ix sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et cooperalires, J.-Albert Gagnon.37301-o 4075-1070 !.G.Corrivcau inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il u accordé des lettres patentes, en date du 23c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Pierre Lalandc, avocat, 1, Place Laval, Laval, Denise Vuliqucttc, épouse «le Jean-Georges Girard, 1081, Sauvé est, cl Ginette lluneaull, fille majeure, 72S3.Herri, ces deux dernières secrétaires, dc Montréal, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de tous articles pharmaceutiques cl médicaux, sous le nom de « L.(ï.Corrivcau inc.-, avec un capital total de $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,900 actions privilégiées dc SU) chacune.Le siège social «le la compagnie est 213A, rue Sud, Cowansville, district judiciaire de Hcdford./.c sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Houciiaud.37391-0 39S1-1970 < i'\"l'ion Realties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dé la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de septembre 1970, constituant en corporation: John Ciaccia, 110, Hcaconsfield, Bcncons-ficld, David Katznt'lson, 5520, avenue Ashdale, Côte Saint-Luc, Robert Litvack, 590, avenue Stanslead, Mont-Royal, et Bernard Rcis, 213, chemin Finehley, Hampstead, tous les quatre avocats, pour les objets suivants: Étublir et diriger une compagnie d'immeuble, dc construction cl dc placement, sous le nom de « Crofton Realties Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 «diacunc et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 1, place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391 4147-1970 D.T.S.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 9e jour de juin 1970, constituant en corporation: Jacynthc Bayard, 3230, Cap à l'Aigle, Laval, Monique Charron, 6847, dc la Roche, toutes deux filles majeures, et Lise Carignan, épouse de Yvon Robert, 9717, Iberville, ces deux dernières de Montréal, toutes trois secrétaires, pour les objets suivants: Établir et maintenir un laboratoire et un bureau pour opérations de recherches scientifiques et d'études dans le domaine dc l'élcctro- Thc head office of the corporation is at Rimouski, judicial district of Rimouski.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperative*.37391 407: 1970 L.G.Corrivcau inc.Notice is given that under l'art 1 of Companies Act, letters patent, bearing dale the 23rd day of September, 1970.have been issued by the Minister of Financial Institutions, Com-panics and Cooperatives, incorporating: Pierre Lalandc, advocate, 1 Place Laval.Laval, Denise Valiqucttc, wife of Jean-Georges Girard.Iiis| Sauvé Hast, and Ginette lluneaull, spinster of thc full age of majority, 72S3 Herri, the hitter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all pharmaceutical and medical articles, under thc name of \"1.(i.Corrivcau inc.\", with a total capital slock of 810,000, divided into 1,000 common shares of S| each and into 3,900 preferred shares of Sill each.The head office of the company is at 213A Sud Street, Cowansville, judicial districl of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 39S1-1070 Crofton Realties Inc.Notice is given that under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing dale Ihe 22nd day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: John Ciaccia, 110 Hcaconsfield, Hcaconsfield.David Kal/.nclson, 5526 Ashdale Avenue, Côte Saint-Luc, Robert Litvack, 590 Stanslead Avenue, Mount Royal, and Bernard Rcis, 213 Finchky Road, Hampstead, all four advocates, for Ihe following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Crofton Realties Inc.\".with a total capital stock of 840,000.divided into 1.IHKI common shares of the par value of 81 each and 36,000 preferred shares of the par value of $1 each.Thc head ollicc of thc company is at I Place Ville Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financ \"/ Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4117 1070 D.T.S.inc.Notice is given lhat under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of June, 1970, have been issued by lhorating: Herman Roy, trader, Talbot Boulevard, Laterrièrc, Basile Savard, manager, 57 Gaudreault, and Adjutor Duchesne, labourer, 42 Purent, the latter two of Misliissini, for thc following purposes: To operate hotels, taverns, inns and restaurants, under thc name of \"Hotel Motel Amico inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of S100 each.The head ollicc of the company is al Laterrièrc, judicial district of Chieoutimi.Ls-PllILIPPE rouciiakii, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4008-1970 Moid-M n 1 el La Brinde, inc.Notice is given that under Purt I of thc Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Françoise Côté, wife of Gérard-J.Delagc, 605 Royale, Bcauport, Gabricllc Côté, widow of Paul-Armand Fisct, both housewives, and Robert Fisct, businessman, the latter two of St-Jean-Baptiste Street, Baie-Soint-Paul, for the following purposes: To operate hotels, motels, taverns, inns, restaurants and swimming pools, under thc name of \"Hotel-Motel Lu Brinde, inc.\", with 11 total capital stock of 860,000, divided into 100 common shares of $100 each und into 500 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Baic-Suint-Paul, judicial district of Sagucnay.Ls-Pmlippe Bouciiaiid, Deputy M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3923-1970 Pierre 11 mini ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Tessier, advocate, 107 Hudon, Rimouski, Pierre Huard, salesman, and Sylvettc Leblanc, housewife, wife of said Pierre Huard, the latter two of Saintc-Adcluïde-dc-Pubos, for the following purposes: To operate hotels, motels, taverns, inns and restaurants, under the name of \"Pierre Huard ltéc\", with a total capital stock of 840,000, divided into 40,000 common shares of SI each.The head office of the company is at Grande-Rivière, judicial district of Gaspé.J.-Ai.iikrt Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3939-1970 Huiles Budget inc.Budget Fuels Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michel Cogger, 376 Rcdfern, Peter C.Casey, 453 Grosvenor Avenue, both of Westmount, Raymondc Ver- GS22 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n\" 1,8 Ruymoudc Ycrrèault, 5412, Coolbrook, tous trois avocats, Mariette Duprë, 6550, 19c Avenue, et.Dcsncigcs Lanthicr, 300, Cote Vertu, ces deux dernières .secrétaires, ces trois dernières célibataires, de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'huiles à combustion pour fournaises, poêles cl engins diesel, sous le nom dc « Huiles Budget inc.\u2014 Budget Fuels Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 3.500 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.I.e siège social de la compagnie est.5480, rue l'are, Montréal, district judiciaire dc Montréal./.use dc Kenneth Dollingcr, 5615, Emerald, Côte Saint-Luc, et Abraham Slawncr, avocat, 159, Braeside, Dollard-des-Onneaux, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc toutes sortes de meubles, accessoires, et appareils, carpettes, tapis, moquettes et machinerie, sous le nom dc « Montreal Furniture Traders Ltd.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilii'I'e Bouchard.37391 4120-1970 Montreal Furniture Traders Ltd.Notice is given that under Part I of I lie Companies Act.letters patent, bearing (late I lie 5th day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Blinda Levine, executive, widow of Samuel Bronslcm, 2290 Valade, Saint-Laurent, Judith Lccker, secretary, wife of Kenneth Dollingcr.5615 Emerald, Côte Saint-Luc, and Abraham Slawncr, advocate, 159 Bracside, Dollard-dcs-Ornicaiix, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of furniture, fixtures and appliances, mats, rugs, cat pels and machinery, under the name of \"Montreal Furniture Traders Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 20,000 con.mon shares of a pur value of 81 each and 20,000 preferred shares of a par value of 81 each.The head office of the company is at Moid real, judicial district of Montreal.Ls-PniLTPPE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institution*.Companies and Cooperalires.¦ 37391-0 4120-19.0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 Nation & frcrc inc.be ministre des instilulioiis financières, compagnies el coopératives donne avis, qu'en vertu de lu première partie dc lu Loi des compagnies, il a necordé des lettres patentes en date du 10c jour de septembre 1970, constituant en corporation.Jacques Nation, 1435, rue Fcrnand, René Nation, tous deux entrepreneurs, et Francinc Nadon, ménagère, épouse dudit René Nadon, res deux derniers dc 1443, Bord de l'Eau, tous |roi> 'le l.aval, pour les objets suivants: Faire alFaircs comme constructeurs et entre-preiii ors généraux en construction et fuirc le commerce de toutes sortes dc matériaux, sous le nom de « Nadon & frère inc.», avec un capital total île $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaire- d'une valeur nominale dc SI chacune et en 2011 actions privilégiées d'une valeur nominale île $100 chacune.I.e -iège social de la compagnie est 1443, llonl de l'Eau, Laval, district judiciaire dc Montréal.I.Csous-linhistrë associé des inslilnlious financières, compagnies cl cooperalires, J.-Ai.beht Gagnon.Î7301-o 3914-1970 Yves Nui in.nul in inc.I.e ministre des institutions financières, com-piignic- et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie dc la Loi des compagnies, il a m-.>nié lettres patentes, en date du 22e jour ¦le scpli mlirc 1970, constituant en corporation: Claude-F.Fortin, gérant, 3155, Marsolet, Yves N'ormandin, 2839, Toussaint-Dussault, et Guy llerger.ui.3463, du Gué, ces ceux derniers vendeurs, tous trois de Suinlc-Foy, pour les objets suivants: Faire affaires comme courtiers, agents ou représentants pour toutes compagnies, associa-lion» el syndicats, sous le nom de « Y'vcs Nor-mandin inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et en 2,000 actions privilégiées dc S10 chacune l.e «iège social dc la compagnie est 640,St-Jcan, suite 316, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-minislre des inslilnlious financières, compagnies cl cooperalires, Ls-Philippe Bouciiaiid.37391-d 965-1970 O.F.I, limitée l.e ministre îles institutions financières, compagnie» et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a necordé des lettres patentes en date du 8e jour de septembre 1970, constituant en corporation: (iérard Germain, 69, Place Fiset, Repentigny, Jacques Synnolt, 1245, Croissant Deau-villc, l.aval, et Normand Gauthier, 1465, boulevard l.ebel, Chambly, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc placement et agir comme prêteurs d'argent dans toutes ses spécialités, sous le nom de « O.I'M, limitée », avec un capital total de S80.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 4,000 actions pnvilégiées de $10 chacune I.e .siège social de la compagnie est 6200, rue ( ¦sgrain, Montréal, district judiciaire dc Montreal.sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Ai.beht Gagnon.«301-o 4059-1970 0833 Nadon & frère inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters liaient, bearing date the 10th day of Septeinlier, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Nadon, 1435 Femand Street, René Nadon, both contractors, and Francinc Nadon, housewife, wife of the said René Nadon, the fuller two of 1443 Bord de l'Eau, all three of Laval, for the following puiposo: To do business as builders and general contractors in building and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Nadon & frère inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of $1 each and 200 preferred shares of a nominal value of S100 each.The head office of the company is at 1443 Bord de l'Eau, Laval, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperalires.37391 3914-1970 Yves Normundin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters liaient, bearing date the 22nd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claudc-P.Fortin, manager, 3155 Marsolet, Y'vcs Normundin, 2839 Toussaint-Dussault, et Guy Bergeron, 3463 du Gué, the latter two salesmen, all three of Sainte-Foy, for the following purposes: To carry on business us brokers, ugents or any company representatives, associations and syndicates, under the name of \"Yves Normundin inc.\", with u total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 640 St-.lcan, Suite 316, Québec, judicial district of Québec.Lb-Piiilippe Boi'ciiahd, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391 965-1970 O.F.I, limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gérard Germain, 69 Fiset Place, Repentigny, Jacques Synnolt, 1245 Deauvillc Crescent, Laval, and Normand Gauthier, 1465 Lebel Boulevard, Chambly, all three businessmen, for the following purposes: To do business as a placing company and to act as money-lenders in all its branches, under the numc of \"O.I'M, limitée\", with a total eapitul stock of $80,000, divided into 4,000 common shares of $10 each and 4,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 6200 Gusgrain Street, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperatives.37391 4059-1970 G834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n\" J,S Ore Imports Inc.1a ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il n aecordé des lettres patentes en date du 14c jour de septembre 1970, constituant en corporation Gary Moscowitz, 260, St-Aubin, Saint-Laurent, Paul Nad 1er, 800 Rockland, #405, Outremont, Philip Shaposnick, 6870, Chester avenue, et David Goldcnhlalt, 3500, de la Montagne, #67.ces deux derniers dc Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Paire le commerce de marchandises de toutes sortes, sous le nom «le « Oré Imports Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et.en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale «le S100 chacune.Le siège social «le la compagnie est 2015, rue Drummond, suite 710, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des inslilnlious financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon-.3739 l-o 4002-1970 Pacific Construction Ltd.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies, il a accorde des lettres patentes, en «latc «lu 15c jour «le septembre 1970, constituant en corporation Giacomo Giorgio Sand, 211, Dresden, Mont-Royal.Rrahm L.Campbell, 43.Aldrcd Crescent, Hampstead, et William Schwartz, 7452, Oslell Crescent, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie dc construction, sous le nom «le « Pacific Construction Ltd.».avec un capital total dc 540,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc S10 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 497, Alexis-Nihon, Saint-Laurent, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies cl coopératives.J.-Albert Gagnon.37391 4046-1970 Papeterie Rapide limitée Le ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives «lonnc avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en «latc du 4c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Jean Bazin, 218 Berlioz, Guy Allain, 5267, Byron, tous deux dc Montréal, et Vinccnt-F.Lcfcbvrc, 120 dc Flandre, Saint-Lambert, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exploiter un commerce d'imprimeurs, sous le nom de « Papeterie Rapide limitée », avec un capital divisé en 1,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou au pair et 400 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune Le siège social dc la compagnie est à Scpt-Ilcs, district judiciaire de Hauterivc.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et cooperalires, J.-Albert Gagnon.37391 3866-1970 Gaudias Parent inc.Ore Imports Inc.Notice is given that under Part I of i|\u201e.Companies Act, letters patent, bearing date I lie 14th day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Com.panics and Cooperatives, incorporating: Garv Moscowilz, 260 St-Aubin, Saint-Laurent, I'aul Nadler, 900 Rockland, #405, Outremont.I'lnlip Shaposnick, 6870 Chester Avenue, and David Goldenblatt, 3500 Mountain street, #67, Ihe latter two of Montreal, all four advocates.Uir the following purposes: To do business in merchandise of all hinds, under the name of \"Ore Imports Inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 20,000 common shares of a nominal value of SI each and 200 preferred shares of a nominal value of snifl each.Thc head office of thc company is at 2015 Drummond street, suite 710, Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minisler of Financial Institutions, Companies and Coopérai in >.37391 4002-1970 Pacific Construction lid.Notice is given that under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing date Ihe 15th day of September, 1970.have l>ccn issued by the Minister of Financial Institutions.Compagnies anil Cooperatives) incorporating: Giacomo (iiorgio Sand, 211 Dresden.Mount Royal, Rrahm L.Campbell, 43 Aldrcd Crescent.Hampstead, and William Schwartz, 7452 Ostell ('res-cent, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Pacific Construction Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of 810 each.Thc head office of the company is at 197 Alexis Nihon, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Coopérai in».37391-0 4046-1970 Papeterie Rapide limitée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: -lean Bazin, 21S Berlioz, Guy Allain, 5267 Byron, both of Montreal, and Vincent-F.Lefcbvre.120 de Flandre, Saint-Lambert, all three advocates, for thc following purposes: To carry on business as printers, under I he name of \"Papeterie Rapide limitée\", with a cupital stock divided into 1,000 common shares without nominal or par value and 400 preferred shares of the par value of 8100 each.Thc head office of thc company is at Sept ' les, judicial district of Hauterivc.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391-0 3866-1970 Gaudias Parent inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu Notice is given that under Part I ol tl'C Companies Act, letters patent, bearing date lb* QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.IS 6835 Je la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Jacques Parent, industriel, Réjcanne Ellef-scn.épouse dudit Jacques Parent, tous deux de 118, Malte, et Marie-Ange Parent, veuve dc Gandins Parent, 7, St-Jules, ces deux dernières ménagères, tous trois de Bcauport, pour les uliji ts suivants: Fabriquer et faire le commerce dc toutes sortes de chaussures, sous le nom dc « Gaudias Purent inc.», avec un capital total de $40,000, divisé eu 4,000 actions ordinaires dc $10 chacune.I.e siège social dc la compagnie est 815, St-Joseph est, Québec, district judiciaire dc Québec.It sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3730 l-o 4189-1970 25lh day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Parent, industrialist, Réjcanne Ellcfscn, wife of said Jacques Parent, both of 118 Matte, and Maric-Ange Parent, widow of Gaudias Parent, 7 St-Julcs, the latter two housewives, all three of Beuuport, for thc following purposes: To manufacture and deal in all kinds of shoes, under the name of \"Gaudias Parent inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of S10 each.Thc head office of the company is at 815 St.Joseph East, Québec, judicial district of Québec.Ls-Pi 11 u ppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4189-1970 Les perrons Métropolitains inc.Li- ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi ties compagnies, il a accordé des lettres patentes en tlatc du 14c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Claude Bernicr, 345, des Saules, Québec, René Routhicr, 116, Monseigneur Dumas, l.orcilevillc, tous deux industriels, et Louise Bouchard, secrétaire, fille majeure, 1296, Chanoine Morel, Sillery, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce du ciment (cl du béton préfabriqué) et dc ses sous-produits, sous le nom dc « Les perrons Métropolitains inc.avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.l.e siège social de la compagnie est 116, Monseigneur Dumas, Lorettevillc, district judiciaire de Québec./.c sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 39S8-1970 Les perrons Métropolitains inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude Bernicr, 345 des Saules, Quebec, René Routhicr, 116 Monseigneur Dumas, Lorettevillc, bolh industrialists, and Louise Bouchard, secretary, spinster of the full age of majority, 1296 Chanoine Morel, Sillery, for the following purposse: To manufacture and to deal in the cement business (and of prefabricated concrete) and its sub-products under the name of \"Les perrons Métropolitains inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of SI0 each.The head office of the company is at 116 Monseigneur Dumas, Lorettevillc, judicial district of Québec.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3988-1970 Phoenix Trading Co.Ltd.I.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en dale du 18e jour de septembre 1970, constituant en corporation.David Weiss, 6300, avenue Lennox, Anthony lîinek, 625, avenue Milton, tous deux ingénieurs, de Montréal, et Irving I.Finkclberg, avocat, 35, Merton Crescent, Hampstead, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce d'automobiles, caniions, autobus, avions, motocyclettes et véhicules motorisés dc toutes sortes, sous le nom de cPhoenix Trading Co.Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 4092-1970 Phoenix Trading Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Weiss, 0300 Lennox Avenue, Anthony Binek, 625 Milton Avenue, both engineers, of Montreal, and Irving I.Finkclberg, advocate, 35 Merton Crescent, Hampstead, for thc following purposes: To manufacture and deal in automobiles, trucks, autobuses, aeroplanes, motorcycles and motor vehicles of all kinds, under the name of \"Phoenix Trading Co.Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a par value of SI each and 20,000 preferred shares of a par value of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4092-1970 6S36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n\" AS Photothèque des Cantons dc PEst inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour d'octobre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Marcel Châteauncuf, photographe, 3S2, rue Alexandre, Guy Charbonnier, commis, 604, rue Gariépy, Roger Dion, électricien, 52S, rue Dollurd, Richard Biais, acheteur, 2895, rue Marieourt, cl G.-Herlcl Beaulieu, représentant, 570, rue Argylc, tous de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire la promotion de photos publicitaires, sous le nom dc « Photothèque des Cantons de l'Est inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 840,000.Le siège social dc la corporation est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le soii.i-mini.tlrc associé des institutions financières, compagnies el coopératives, J.-Albert Gagnon.3739 l-o 3734-1970 Placements J.-C.Miiot inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Jean-Claude Milot, gérant, Fabienne Lévesque, ménagère, épouse dudit Jean-Claude Milot, tous deux dc 630, boulevard Sl-.Ioseph, Drummond ville, et Maurice Martel, avocat, 1301, St-Vinleurouest, Outremont, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille, de placement et de gestion, sous le nom de « Placements J.-C.Milot inc.», avec un capital total de 8100,000, diyisé en 4 actions ordinaires de 810 chacune, 9,994 actions privilégiées classe « A » de 810 chacune et en 20 actions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 030, boulevard St-Joseph, Drumniondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-minislre des instilulioiis financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ii'pi: Bouchard.37391-0 4186-1970 Photothèque des Cantons de l'Est inc.Notice is given that under Part III of ||K.Companies Act, letters patent, bearing dale I be 1st day of October, 1970.have been issued by Ihe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Marcel Châteauncuf photographer, 382 Alexandre Street, Guy Char-bonnier, clerk, 664 Gariépy Street, Roger Dion electrician, 528 Dollard Street, Richard Biais, purchaser, 2895 Maricourt Street, and G.-IIerlcl Beaulieu, representative, 570 Argylc, all of Sherbrooke, for the following purposes: The promotion of publicity pictures, under the name of \"Photothèque des Cantons de l'Est inc.\".The amount to which is limited the value ol I lie immovable property which the corporation may acquire and possess, is 840,000.The head office of the corporation is at Slur-brookc, judicial district of Saint-François.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Coopérai ires.3739 1 3734-1970 Placements J.-C.Milot inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dab- Ihe 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Claude Milot, manager, Fabienne Lévesque.housewife, wifeof said Jean-Claude Milot.bol h of 030 St.Joseph Boulevard, Drumniondville, ami Maurice Martel, advocate, 1301 St-Vialcur West, Outremont, for the following purposes: To carry on business as a holding, investment and management company, under the name of \"Placements J.-C.Milot inc.\", with a tidal capital stock of 8100,000, divided into 4 common shares of 810 each, 9,994 class \"A\" preferred shares of 810 each and into 20 class \"B\" preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Ii3(l St.Joseph Boulevard, Drummondvillc, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperalires.37391 4186-1970 Les placements R.Y.P.Y.N inc.R.Y.P.Y.N.Investments Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour d'août 1970, constituant en corporation: Richard Goulet, agent d'assurances, 301, Duffe-rin, Yvan-M.St-Onge, avocat, 82, Principale, app.2, Yvan Lamourcux, électricien, 443, Lcclerc, Normand Lacoste, commerçant, 188, Dufferin, tous quatre de Granby, et Pierre Vincent, journaliste, 8592, Reims, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de portefeuille (holding), sous le nom de « Les placements R.Y.P.Y.N.inc.\u2014 R.Y.P.Y.N.Investments Inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Les placements R.Y.P.Y.N inc.R.Y.P.Y.N.Investments Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of August, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Goulet, insurance agent, 301 Dufferin, Yvan XI.St-Ongc, advocate, 82 Main, Apt.2, Yvan Lamourcux, electrician, 443 Lcclerc, Normand Lacoste, trader, 188 Dufferin, all four of Granby, and Pierre Vincent, journalist, 8592 Reims, Montreal, for the following purposes: To carry on business as a holding company, under the name of \"Les placements R.Y.P.X X-inc.\u2014 R.Y.P.Y.N.Investments Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shares of $100 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.k8 6837 I.r siege social de la compagnie est à Granby, district judiciaire de Bedford, /.r mis-ministre ties instilulioiis financières, com pay nies el cooperatives, Ls-Pin lippe Bouciiaiid.37391-0 3675-1970 Placements Sl-Malachie inc.I.r ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29c jour de septembre 1970, constituant en corporation: .lames Quigley, gérant, Gérard Pâlichon, commerçant, Réal Dion, épicier, Marcel I.arochclle, chef de gare, Gérard Rucl, marchand, Mivillc Caron, garagiste, et Louis-H.|.ufon laine, gérant dc banque, tous dc Saint-Malachic, pour les objets suivants: l'aire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom dc « Placements Sl-Malachie inc.», avec un capital total de $100.000, divisé en 1,500 actions ordinaires il'iitir valeur nominale de S50 chacune et en 250 actions privilégiées d'une valeur nominale de $100 chacune.l.e siège social de la compagnie est à Saint-Malachie, district judiciaire de Bcauce.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3739 l-o 4264-1970 The head olfice of the company is at Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Instilulioiis, Companies and Coopérai ives.37391 3075-1970 Placements St-Malachic inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of September, 1970, have been issued by the .Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James Quigley, manager, Gérard Faiichon, trader, Real Dion, grocer.Marcel Larochellc, station-master, Gérard Ruel, trader, Mivillc Caron, garage keeper, and Louis-II.Lafontaine, bank manager, all of Saint-Malachie, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Placements St-Malachie inc.\", with a total capital slock of $100,000, divided into 1,500 common shares of a nominal value of $50 each and into 250 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Saint-Malachie, judicial district of Bcauce.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial lust il niions, Companies and Cooperalires.37391 4264-1970 Les placements S.G.R.inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 30e jour île septembre 1970, constituant en corporation: Georges-Henri Fortin, représentant) 792, Sic-Marie, Serge Bessette, 1916, Bourgogne, tous deux de Chnmbly, «et Raymond Fortin, 2045, Ostiguy, Marievillc, ces deux derniers vendeurs, pour les objets suivants: l'aire affaires comme prêteurs d'argent dans Ionics ses spécialités, sous le nom dc « Les placemen Is S.G.R.inc.», avec un capital de S200.000, djvisé en -1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 1,000 actions privilégiées de $100 chacune l.e siège social de la compagnie est à Chambly, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.3739 l-o 3761-1970 Pierre Pocti inc.I.\" ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du ISe jour de septembre 1970, constituant en coloration: Alain Côté, avocat, Suzanne Bcauchamp, institutrice, épouse dudit Alain Côté, tous deux de 117, Carignan, et Claude Bcauchamp, commis, 196, Tournclle, tous troisdeLaval, pour les objets suivants: Faire affaires comme électriciens; fabriquer cl faire le commerce de toutes sortes d'appareils \u2022>l accessoires électriques, sous le nom de « Pierre Pocti inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de $100 chacune l.e- placements S.G.R.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30lh day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incor|>orating: Georges-Henri Fortin, representative, 792 Ste-Marie, Serge Bessette, 1916 Bourgogne, both of Chambly, and Raymond Fortin, 2045 Ostiguy, Marie-ville, the lutter two salesmen, for the following purposes: To do business as money-lenders in all its branches, under the name of \"Les placements S.G.R.inc.\", with a total capital stock of S200.000, divided into 4,000 common shares of $10 each and 1,600 preferred shares of S100 each.Thc head office of the company is at Chambly, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3761-1970 Pierre Poeti inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date thc 18th day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incor]>orating: Alain Côté, advocate, Suzanne Bcauchamp, teacher, wife of the said Alain Côté, both of 177 Carignan, and Claude Bcauchamp, clerk, 196 Tournclle, all three of Laval, for the following purposes: To do business as electricians; to manufacture and to deal in all kinds of appliances and electric accessories, under the name of \"Pierre Poeti inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of $100 each. 6S3S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n\" A8 Le siège social de la compagnie est 2745, Hector, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des instilulioiis financières, compagnies cl coopératives, J.-Albekt Gagnon.37391-0 4065-1970 Poliplastic Granby ltéc Poliplastic Granhy Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes en date du 22e jour dc septembre 1970, constituant en corporation: André Nadcau, industriel, Micheline Na-deau, ménagère, épouse dudit André Nadcau, tous deux dc 246, rue Mullin, et Gilles Fausse, comptable, 251, Mullin, tous trois dc Granby, pour les objets suivants: Manufacturer cl faire le commerce de lotis produits quelconques d'emballage que ce soit ou non en plastic, sous le nom dc « Poliplastic Granby ltéc \u2014 Poliplastic Granby Ltd.», avec un capital total de 510,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 390 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 415, rue St-Vallicr, Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albekt Gagnon.37391-0 4184-1970 The head office of thc company is at 2745 Hector, Montreal, judicial district of Montreal, J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératives, 37391 4005-1970 Poliplastic Granby liée Poliplastic Granby Ltd.Notice is given that under Part I of Hie Companies Act, letters patent, bearing dale I lie 22nd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Coin: panics and Cooperatives, incorporating: André Nadcau, industrialist, Micheline Nadcau, housewife, wife of said Andre Nadcau, both of 240 Mullin Street, and Gilles Fausse, accountant, 251 Mullin, all three of Granby, for the following purposes: To manufacture and to deal in all kinds ()f wrapping materials cither in plastic or not, under the name of \"Poliplastic Granby ltéc \u2014 Poliplastic Granby Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 51 each and 390 preferred shares of SI00 each.The head office of the company is at 415 St-Vallicr Street, Granby, judicial district of Bedford.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.37391 4181-1970 Polly Prim Cleaners & Shirt Launderers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Wolfe M.Friedman, 5750, avenue Smart, Sydney Phillips, 5016, avenue Palmer, tous deux avocats, dc Côte Saint-Luc, et Gladys Kobalcnko, secrétaire, fille majeure, 315, avenue Rielle, Verdun, pour les objets suivants: S'établir nettoyeurs à sec, presscurs, teinturiers, et faire la réparation dc vêtements, tissus, articles et fournitures dc maison, sous le nom dc « Polly Prim Cleaners & Shirt Launderers Inc.», avec un capital total dc 540,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 6801, avenue Fielding, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des instilulioiis financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391 3396-1970 Pont Vian Employment Services Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2c jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Farid A.Cheftechi, 135, place Côte Vertu, app.303, John Hamilton, fils, 5820, dc Louis-bourg, app.26, tous deux dc Montréal, et Thomas H.Buck, 571, avenue Patricia, Greenfield Park, tous trois commis juridiques, pour les objets suivants: Polly Prim Cleaners & Shirt Launderers Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Wolfe M.Friedman, 5750 Smart Avenue, Sydney Phillips, 5616 Palmer Avenue, both advocates, of Côte Saint-Luc, and Gladys Kobalcnko, secretary, spinster, 315 Rielle Avenue, Verdun, for the following purposes: To carry on business us cleaners, pressers, dyers, and repairs of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Polly Prim Cleaners & Shirt Launderers Inc.\", with u total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares having a par value ol Si each and 3,000 preferred shares having a par value of 510 each.Thc head office of the company is at 6801 Fielding Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391-0 3996-1970 Pont Viau Employment Services Ltd.Notice is given that under Part I of ihe Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of October, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Farid A.Cheftechi, 135 Place Côte Vertu, Apt.303, John Hamilton, junior, 5820 tie Louisbourg, Apt.26, both of Montreal, and Thomas II.Buck, 571 Patricia Avenue, Greenfield Park, all three law clerks, for the following-purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1070, Vol 102, No.48 0839 S'établir conseillers et agents auprès dc toutes entreprises privées ou commerciales ou auprès ,fétablissements industriels en matière de recherche el ou île sélection du personnel, sous le nom ,1e l'ont Viau Employment Services Ltd.», avec mi capital actions divisé en 40,000 actions -mi- valeur au pair.I.e -iège social de lu compagnie est à Laval, district judiciaire de Montréal.le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-PlIILIPPE Boi'chard.37391 4319-1970 Pram Pants Inc.l.e ministre des institutions financières, compagnie- cl coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de septembre 1970, constituant en corporation: tîary Moscowitz, 200, St-Aubin, Saint-Uurent, David Goldcnblatt, 3500, iSlountain, ¦io.Montréal, et Paul Xadler, 900, Rockland, fltlô.Outremont, tous trois avocats, pour les objets suivants: Confectionner «les vêtements, articles vestimentaires, fournitures, accessoires et habillements île toutes sortes, en faire le commerce, sous le nom de « Pranx Pants Inc.», avec un capital total dc §40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.I.e siège social de la compagnie est 1199, rue llleury.Montréal, district judiciaire de Montréal.I.r sous-minislre des instilulioiis financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391 4089-1970 Prcski inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi ties compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en tlatc du 9c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Holland Fleurant, commerçant, Rcina Pcrrcault, ménagère, épouse dudit Rolland Fleurant, tous «leux de Saint-Jovite, Jacques Bohé-micr.commerçant, et Jean ni ne Roy, ménagère, épouse dudit Jacques Bohémier, ces tleux tlernicrs de 7ll7.9e Rue, Suint-Antoine-dcs-Laurcnlidcs, |ioiir les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce d'un appareil pour briser lu glace sur les pentes tic ski et en faire de la neige douce, sous le nom tic « Prcski inc.avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de -sl chacune et en 20,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de SI chacune.Le siège social tic la compagnie est 1, rue Dumoulin, Saint-Jovite, district jutliciairc tic Tcrrc-bomic.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 3455-1970 Prêts Dico inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes en date tlu 25e Jour de septembre 1970, constituant en corporation: René Landry, chauffeur de taxi, Guy Crête, To act as consultants and agents for any personal or commercial enterprise or for any industrial organization in the search and/or selection of personnel, under the name of \"Pont Viau Employment Services Ltd.\", with a capital stock divided into 40,000 shares without pur value?The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institut ions, Companies and Cooperatives.37391-t) 4319-1970 Pranx Pants Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing tlatc the 18th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies und Cooperatives, incorporating: Gary Moscowitz, 200 St.Aubin, Saint-Laurent, David Goldcnblatt, 3500 Mountain, #67, Montreal, antl Paul Natllcr, 900 Rockland, #405, Outremont, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and ileal in clothing, wearing apparel, furnishings, accessories and garments of every tlescription, under the name of \"Pranx Pants Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of SI each antl 30,000 preferred shares of SI each.Thc head office of the company is at 1199 BIcury Street, Montreal, judicial tlistrict of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391-0 4089-1970 Prcski inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing tlutc the 9th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies antl Cooperatives, incorporating: Rolland Fleurant, tratler, Rcina Pcrrcault, housewife, wife of said Rolland Fleurant, both of Saint-Jovite, Jacques Bohémier, tratler, antl Jcannine Roy, housewife, wife of saitl Jacques Bohémier, the latter two of 707, 9th Street, Saint-Antoinc-tlcs-Laurcntidcs, for the following purposes: To manufacture antl ileal in an apparatus for breaking ice on the ski slopes antl turn it into soft snow, under the name of \"Prcski inc.\", with u total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of a nominal value of 81 each and 20,000 preferrctl shares of a nominal value of 81 each.The head office of thc company is at 1 Dumoulin Street, Saint-Jovite, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3455-1970 Prêts Dico inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: René Landry, taxi chauffeur, Guy Crête, broker, and 6S40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre J970, 102e année, n° 1,8 courtier, et Raymond Drouin, voyageur dc commerce, tous trois de Sainte-Marie, pour les objets suivants: Faire affaires comme prêteurs d'argent dans toutes ses spécialités, sous le nom dc « Prêts Dico inc.>, avec un capital Lotal dc $300,000, divisé en 25,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 5,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Sainte-Marie, district judiciaire dc Beaucc.Le sous-minislre associé des inslilnlious financières, compagnies cl coopératives, J.-Albekt Gagnon.37391-0 2090-1970 Process Piping Specialties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 15c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Egcrton Bakchnun, 8107, du Ghar-donnel, Louis Brian Bakchnun, tous deux marchands, et Maureen Bakchnun, ménagère, épouse dudit Louis Brian Bakchnun, ces deux derniers de 8590, D'ÂlIonnes, tous trois d'Anjou, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce des tuyaux et tuyauterie dc matériel varié et accessoires connexes, sous le nom de « Process Piping Specialties Inc.', avec un capital total de $10,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de SU) chacune et 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 8590, rue D'AlIonnes, Anjou, district judiciaire de Montréal.IjC sous-minislre associé des institutions, financières, compagnies el coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 4041-1970 Les produits alimentaires La Belle Frite inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Jean-Jacques Pilon, industriel, 217, Brière, Jean-Pierre Pilon, opérateur, 353, boulevard Stc-Marccllc, tous deux dc Saint-Jérôme, el René Lafortune, agent, 705, 8c Avenue, Saint-Antoine, pour les objets suivants: Faire le commerce de produits alimentaires de toutes sortes, sous le nom dc « Les produits alimentaires La Belle Frite inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 30,000 actions ordinaires d'une valeur nominale de SI chacune et en 10,000 actions privilégiées d'une valeur nominale dc $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Antoine, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Puilippe Bouciiaiid.37301-o 4035-1970 Publicité & photos couleurs Montréal inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'août 1970, constituant en corporation: Edward J.Drukcr, 5763, McMurray, Morden Lazarus, 5554, Chemin Earlc, tous deux dc Côte Saint-Luc, et Robert G.Wolfe, 2050, De Mai- Raymond Drouin, commercial traveller, all three of Sainte-Marie, for thc following purposes: To do business as money-lenders in all its branches, under the name of \"Prêts Dico inc.\" with a total capital slock of $300,000, divided into 25,000 common shares of $10 each ami 5,000 preferred shares of Sit) each.The head office of the company is at Sainte-Marie, judicial district of Beauce.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Miuislcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 20911-1970 Process Piping Specialties Inc.Notice is given that under Part I of tlie Companies Act, letters patent, bearing dale Ihe 15th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fgcrton Bakchnun, 8407 du Chardomiet.Louis Brian Bakchnun, both merchants, and Maureen Bukcl-liiim, housewife, wife of the said Louis Brian Bakelniun, the latter two of 8590 D'AlIonnes, all three of Anjou, for the following purposes: To manufacture and deal in pipes and piping of various materials, and accessories thereto, under the name of \"Process Piping Specialties Inc.\", with a total capital slock of 840.009, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 8590 D'AlIonnes Street, Anjou, judicial district of Montreal.J.tAlbert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ins.37391-0 4011-1970 Les produits alimentaires La Belle Frite inc.Notice is given that under Pari I of the Companies Act, letters patent, bearing date thc 8lh day of September, 1970, have been issued by Ihe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Jacques Pilon, industrialist, 217 Brière.Jean-Pierre Pilon, operator, 353 Ste-Marccllc Boulevard, both of Saint-Jérôme, and René Lafortune, agent, 705, 8th Avenue, Saint-Antoine, for Ihe following purposes: To deal in food products of all kinds, under the name of \"Les produits alimentaires Lu Belle Frite inc.\", with a total capital stock of $40,000.divided into 30,000 common shares of a nominal value of $1 each and into 10,000 preferred shares of a nominal value of $1 each.The head office of the company is al Saint-Antoine, judicial district of Terrebonne Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instilulioiis.Companies and Coopérai ins.37391 4035-1970 Publicité & photos couleurs Montréal inc.Notice is given that under Part I ol the Companies Act, letters patent, bearing dale the 7th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Edward .1.Drukcr, 5763 McMurray, Morden Lazarus, 5551 Kane Road, both of Côte Saint-Luc, and Robcrl (>\u2022 Wolfe, 2050 De Maisonncuvc, Apt.#12041, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.A8 6841 sonnciivc, app.#1204, Montréal, tous trois avocat'.1»\"\"' 'es objets suivants: j-'uiri' affaires comme imprimeurs, éditeurs, photographes et publicistes, sous le nom de < Publicité & photos couleurs Montréal inc.», av.- mi capital total de S40.000, divisé en 2,000 actio!' \u2022 ordinaires d'une valeur nominale de 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées d'une «leur nominale de S10 chacune.I.e siège social dc la compagnie est 140, rue Fleury ouest, Montréal, district judiciaire de Muni réal./.,¦ mu ministre des instilulioiis financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Houciiaud.37391-0 3446-1970 O.V.N.Investnieiits Inc.I.e ministre des institutions financières, compagnie-, et coopératives donne avis, qu'en vertu de In première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Vlcxander S.Konigsherg, 2378, Frenetic, Saiul-l.aiircnt, Murk Kosenstcin, 5003, Lacomhc, cl Jacques Lcmnitre-Augcr, 8462, Drolet, ces Jeux derniers de Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie d'immcti-hlcs, de construction et dc placements, sous le nom de « Q.A.N.Investments Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.l.e -iège social dc la compagnie est 5611, Chainli.rland Crescent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Ixsans ministre des instilulioiis financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Houciiaud.37391 4048-1970 R.P.B.Holdings Inc.I.c ministre des institutions financières, compagnie- et coopératives donne avis, qu'en vertu de In première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Morton Hell, 701, Rcrtrnnd Drive, Suint-Laurent, Stanley Cytrynbaum, 234, Sheraton Drive, Montréal-Ouest, tous deux avocats, et Audrey Melanson, secrétaire, é|>ouse de Edouard Melanson, 3576, rue Durocher, Montréal, i>our le~ objets suivants: Exercer les affaires d'une compagnie dc portefeuille, sous le nom dc « R.P.B.Holdings Inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 15,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 2,500 actions privilégiées dc S10 chacune.I.c siège social dc la compagnie est 7645, hennin-, Saint-Léonard, district judiciaire dc Montréal.Li Itnis-m inistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiiuppe Houciiaud.37391 3950-1970 Réseau oses: To carry on business as general contractors, builders and suppliers of building materials and construction equipment, under the name ol \"S.T.P.A.Inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 240 common shares of 850 each antl 280 prcferretl shares of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Bouchard, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 75-1970 St-Gclais & fils ltéc Le ministre ties institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tic la première partie tic la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes en tlatc tlu 16c jour tic septembre 1970, constituant en corporation: Raymond St-Gelais, contremaître, Claude St-Gelais, technicien, tous deux tic 264, Davy, Germain St-Gclais, concierge, 543, Hunt, Clarence Greene, opérateur, 384A, Villeneuve, Yves St-Gelais, professeur, 320, Racine, et Mario Sl-Gclais, gérant, 225, Taschereau, tous tl'Arvitla, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, tic construction et tic placement, sous le nom de < St-Gclais & fils Itée», avec un capital total tic S40.000, divisé en 4,000 actions ortlinaircs tic S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Arvitla, district judiciaire de Chieoutimi.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 3077-1970 St-Gclais & fils ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale Ihe 16th day of September, 1970, have been issued by the Minister of F'inancial Institutions, Companies und Cooperatives, incorporating: Raymond St-Gelais, foreman, Claude St-Gekijs, technician, both of 264 Davy, Germain St-Gcluis, janitor, 543 Hunt, Clarence Greene, operator, 384A Villeneuve, Yves St-Gelais, professor.320 Racine, and Mario St-Gelais, manager.225 Taschereau, all of Arvitla, for the following purposes: To carry on business as a real estate, construction antl investment company, under the name of \"St-Gelais & fils liée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4,000 common shares of 810 each.The head office of the company is ut Arvitla, judicial district of Chieoutimi.J.-Albert Bouchard, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopératif'.37391 3077-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6845 Salons de barbier Ferraro inc.Fcrraro Barber Shops Inc.ministre des institutions financières, compagnies et Coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 25c jour de septembre 1070, constituant en corporation: Benito Fcrraro, barbier, Yvette Deniers, professeur, épouse dudit Benito Ferraro, tous lieux dc .'5501, Lagardc, bavai, et Ernest Strolo-ritcli.comptable, 4883, Cumberland, Montréal, pour 1rs objets suivants: Établir, acquérir el vendre des suions dc barbier, -mis le nom dc « Salons dc barbier Fcrraro inc.Ferraro Barber Sbops Inc.», avec un capital total de 840,000; divisé en 10,000 actions onlinoircs dc 81 chacune et en 300 actions privilégiées dc 8100 chacune.l.e siège social dc la compagnie est à Laval, ilislricl judiciaire de Montréal.Le sous-m inixtre des institutions financières, compagnies cl cooperalires, Ls-Philippe Bouciiaiid.37:i0l.o 4210-1970 Sampson Investments Limited l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date «lu 4e jour d'août 1070, constituant en corporation: (i.Harold Pickel, 47, Arlington, Westmount, (iuy-K.Iloisvert, 4970, Glcncairn, tous deux avocats, et Dcnyse Marcoux, secrétaire, fille majeure.1488, Galt, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de portefeuille cl de placement, sous le nom dc « Sampson Investments Limited », avec un cnpilul divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.l.e -iège social de la compagnie est à Montréal, ilislricl judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre associé des inslilnlious financières, compagnies cl coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 3937-1970 Santa Helena Mining Limited l.e ministre des institutions financières, compagnies el coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour de septembre 1970, constituant en corporation: 1.David Fleming, 05, chemin Belvédère, Westmount, Joseph Di Clcmcnti, 4300 ouest, dc Muisoniicuve, Jean-Paul Gagnon, 050, Filiatrault, tous trois avocats, Hugucttc Biais, réceptionniste.2015, d'Iberville, et Micheline Tcdeschi, secrétaire, 9e avenue, ces deux dernières, filles majeures, les quatre derniers dc Montréal, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie minière, sous le nom de « Sauta Helena Mining Limited », avec au capital divisé en 3,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair.l.e siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.-t Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 4142-1970 Roland Schwab inc.Salons dc barbier Fcrraro inc.Fcrraro Barber Shops Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Benito Fcrraro, barber, Yvette Deniers, professor, wife of said Benito Ferraro, both of 3501 Lagardc, Laval, and Ernest Strolovilch, accountant, 4883 Cumberland, Montreal, for the following purposes: To establish, acquire and sell barber shops, under the name of \"Salons de Barbier Fcrraro inc.\u2014 Fcrraro Barber Shops Inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391 4210-1970 Sampson Investments Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 4lh day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: G.Harold Pickel, 47 Arlington, Westmount, Guy-E.Bois-vcrt, 4970 Glcncairn, both advocates, and Dcnysc Marcoux, secretary, spinster, 1488 Gait, the latter two of Montreal, for thc following purposes: To carry on the business of a holding and investment company, under the name of \"Sampson Investments Limited\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial 1 nslitulions, Companies and Cooperatives.37391-0 3937-1970 Santa Helena Mining Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24lh day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: I.David Fleming, 05 Belvedere Road, Westmount, Joseph Di Clcmcnti, 4300 dc Maisonncuvc West, Jean-Paul Gagnon, 656 Filiatrault, all three advocates, Hugucttc Biais, receptionist, 2615 d'Iberville, and Micheline Tcdeschi, secretary, 9th Avenue, the latter two spinsters, the latter four of Montreal, for the following purposes: To carry 011 the business of a mining company, under the name of \"Santa Helena Mining Limited\", with a capital stock divided into 3,000,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4142-1970 Roland Schwab inc.I.e ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu Notice is given that under Part I of th» Companies Act, letters patent, bearing date the G846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre J970, 102' année, n° 18 dc lu première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes en date du 21c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Jacqueline Simoncau, secrétaire, fille majeure, 347, rue St-Georges, Roland Schwab, importateur, et Denysc Langlois, ménagère, épousé dudit Roland Schwab, ces deux derniers dc GOO, Grande-Allée, tous trois dc Saint-Jérôme, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de montres, horloges, pendulettes et accessoires connexes, sous le nom de « Roland Schwab inc.avec un capital total dc S100;000, divisé en 3,000 actions ordinaires dc S10 chacune et en 700 actions privilégiées dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 434, rue Labelle, Saint-Jérôme, district judiciaire dc Terrebonne.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391-0 4097-1970 Seinicterrc Fly-In Camps Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 17e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Guy Hilodeau, directeur d'écoles, 870, 6e Rue, André Hilodeau, piloté commercial, et Bertrand Hilodeau, journalier, ces deux derniers de route rurale #6, tous trois de Senncterrc, pour les objets suivants: Faire affaires comme pourvoyeurs, sous le nom dc « Senncterrc Fly-In Camps Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est S70, 6e Avenue, Senncterrc, district judiciaire d'Abilibi.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albeht Gagnon.37391-0 3903-1970 Service central dc distribution (.Montréal) inc.I,e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 22c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Bernard Rvraire, 27, Duvergcr, Outremont, Paul Giguère, tous deux industriels, et Suzanne Dussault, ménagère, épouse dudit Paid Giguère, ces deux derniers dc 67, Courtney Drive, Montréal-Ouest, pour les objets suivants: Faire le commerce et la distribution dc brochures, périodiques, livres d'école et autres et toutes espèces dc matière imprimée, sous le nom de « Service central de distribution (Montréal) inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de 810 chacune Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Bouchard.3739 l-o 3427-1970 Service dc soins à domicile dc Rimouski inc.21st day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, C(,m.panics and Cooperatives, incorporating: Jacqueline Simoneuu, secretary, spinster of the full age of majority, 347 St-Gcorgcs Street, Roland Schwab, importer, and Dcnysc Langlois, house-wife, wife of said Roland Schwab, the lutter two of G00 Grande-Allée, all three of Saint-Jérôme for the following purposes: To manufacture and deal in watches, clocks, travelling-clocks and accessories related thereto, under the name of \"Roland Schwab inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divide! into 3,000 common shares of $10 each and into 7(10 preferred shares of S100 each.Thc head office of the company is at 434 Labelle Street, Saint-Jérôme, judicial district of Terrebonne J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 4097-1970 Sennelerre Fly-In Cnmps Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale thc 17th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Companies ami Cooperatives, incorporating: Guy Hilodeau, school principal, 870, 6th Street, André Hilodeau, commercial pilot, and Bertrand Hilodeau, labourer, thc latter two of rural route No.6, all three of Senncterrc, for thc following purposes: To do business as outfitters, under the name of \"Senncterrc Fly-In Camps Inc.\", with a total capital stock of S-10.000, divided into 1,000 common shares of 810 each.Thc head office of the company is al S70, 6th Avenue, Senncterrc.judicial district of Abitibi.J.-Albert Gagnon.Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391 3903-19711 Service central de distribution (Montréal) inc.Notice is given that under Purl I ol II»' Companies Act, letters patent, bearing dale the 22nd day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Evrairc, 27 Duvergcr, Outremont, Paul Giguère, both industrialists, and Suzanne Du-anil, housewife, wife of thc said Paul Giguère, the latter two of 67 Courtney Drive, Montreal-West, for the following purposes: To deal in and distribute pamphlets, periodicals, school books and other and all kinds of printed matter, under the name of ''Service central de distribution (Montréal) inc.\".with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperalires.37391 3427-1970 Service de soins îi domicile dc Rimouski inc.Notice is given that under Part III of lj«\" Companies Act, letters patent, bearing date the Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.AS 6847 de lu troisième partie dc la Loi des compagnies, jl a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de septembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gaétan Bérubé, 263, XoliT-Daine, Jean Desrochcrs, 446, Place Mon-scigueiir Langis, tous deux dc Rimouski, et Lucien Gcndrcau, Luceville, tous trois médecins, pour les objets suivants: Créer un service dc soins à domicile, sous le nom de « Service dc soins à domicile dc Rimouski inc.»\u2022 l.e montant auquel est limitée la valeur des liions immobiliers que peut acquérir et posséder In nirporation, est de S100.000.l.e siège social de la corporation est à Rimouski, ilislricl judiciaire dc Rimouski./.!¦ sous-ministre associé des inslilnlious financières, compagnies el coopératives, J.-Albekt Gagnon.3730I-o 3289-1970 Sherbrooke excavation inc.I.r ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Jean-Louis Oucllet, 2920, Dclormc, Gino Morin, tou> lieux opérateurs, et Aimé Morin, entrepreneur, ces deux derniers de 2935, Delorme, tous Iriii- de Sherbrooke, pour les objets suivants: l'aire affaires comme entrepreneurs généraux, sous le nom dc « Sherbrooke excavation inc.», avec un capital total dc §40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 300 actions privilégiées dc S100 chacune.I.r -iège social dc la compagnie est à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.le tous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PlllI.Il'1'e bouciiahd.37391- 1209-1970 Silcan Mines Ltd.(No personal liability) l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes, en date ilu '-'.V' jour dc septembre 1970, constituant en corporation: James Brian McMullun, 4014, Murcil.Jean-Charles Hamclin, 5369, de Lorimier, tous deux de Montréal, Arnold Beaumont Sharp, 1000, Moncrieff, Paul A.R.Townsend, 72, Hudson, tous deux dc Mont-Royal, et Daniel Harper Tingley, 16, Thornhill, Westmount, tous avocats, pour les objets suivants: Rlablir et diriger une compagnie minière, sous le nom dc « Silcan Mines LUI.» (No personal liability), avec un capital divisé en 5,000,000 actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair.l.e siège social de lu compagnie est à Montréal, ilislricl judiciaire de Montréal./.' mus-ministre associé des institutions financières, compagnies et cooperalires, J.-Albkht Gagnon.3*391 3659-1970 Simply Punts Knits Inc.h\" ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu >niii|> purposes: To carry on the business of an investment ami holding company, under the name of \"Stackpool Enterprises Limited\", with a capital slock divided into 2,000,000 common shares without par value and 500,000 preferred shares ul a par value of S0.25 each.Thc head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Houcuard.Deputy Minister of Financial Institution.', Companies and Cooperatives.37391-0 4114-1970 Summit I .i i Im Ltd.I i tin.Sommet liée Le ministre des instilulioiis financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu île la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 3e jour de septembre 1970, constituant en corporation: James Taylor, imprimeur, 96, Louis Lacoste, Boucherville, Joyce Lnrivière, 10731, Hcnault, Montréal-Nord, Elaine Engclbcrt, 5774, avenue Léger, (Vite Saint-Luc, toutes deux secrétaires, filles majeures, et Edward I).Desaulnicrs, administrateur, 310, rue Logan, Saint-Lambert, pour les objets suivants: S'établir imprimeurs, édietcurs, propriétaires de journaux, lithographes, graveurs, relieurs, libraires, fondeurs typographiques et agents publicitaires, sous le nom de « Summit Litho Ltd.\u2014 Litho Sommet liée», avec un capital total île S40.000, divisé en 10.000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre associé des instilulioiis financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391 3S57-1970 Summit Litho Ltd.Litho Sommet ltéc Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date Ihe 3rd day of September, 1970, have been issued hy the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James '1 aylor, printer, 96 Louis Lacoste, Boucherville, Joyce Larivière, 10731 Hcnault, Montreal North, Elaine Engclbcrg, 5774 Léger Avenue, Côte Saint-Luc, both secretaries, spinsters, and Edward I).Desaulnicrs, executive, 310 Logan Street.Saint-Lambert, for the following purposes: To carry on business as printers, publishers, newspaper publishers, lithographers, engravers, bookbinders, booksellers, type founders and advertising agents, under the name of ''Summit Lifho Ltd.\u2014 Litho Sommet ltéc\", with a total capital stock of S40.000, divided into lli.IMM common shares of a par value of SI each and 30,000 preferred shares of a par value of SI each.The head office of thc company is al Montréal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 37301-o 3857-1970 Talva inc.Le ministre des institutions financières, compagnies el coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il n accorde des lettres patentes, en date du 16e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Gérard Savard, commerçant, 581, Meilleur, Gaston Savard, notaire, 105, rue Lomas, H.-Paul Gobcil, comptable, 176, Bryant, et Edouard Chassé, gérant, 1484, Bowcn sud, tous quatre de Sherbrooke, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble, de construction, de placement et de portefeuille, sous le nom dc «Talva inc.», avec un capital total dc 8200,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc 81 chacune et en 19,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Talva inc.Notice is given Hint under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 16th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.( \"in-panies and Cooperatives, incorporating: Gérard Savard, trader, 581 Meilleur, Gaston Savard.notary, 105 Lomas Street, H.-Paul Gokil.accountant, 176 Bryant, und Edouard Chassé, manager, 1484 Bowcn South, all four of Sherbrooke, for the following purposes: To curry on business as a real estate, construction, investment and holding company, under the name of \"Talva inc.\", with a total capital stack of $200,000, divided into 10,000 c.mon shares of $1 each and into 19,000 preferred shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.18 6851 |,c siège social (le la compagnie est à Sherbrooke district judiciaire dc Saint-François.I.r sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagxox.37391-0 2535-1970 The head office of the company is al Sherbrooke, judicial district of Saint-François.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 2535-1970 Tapis Québécois inc.l.e ministre des institutions financières, compagnie et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 25e jour de septembre 1970, constituant en corporation: (iillcs Lamontagnc, gérant, 6965, 8e Avenue est, Charlesbourg, Jean-Paul Gariépy, 395, des Peupliers ouest, et Roland Lavcrdière, 142, des Chênes ouest, ces deux dentiers commerçants, de Québec, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de tapis et couvre-planchers, sous le nom dc « Tapis Québécois inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1.000 actions ordinaires de §10 chacune et en 3.000 actions privilégiées de S10 chacune l.e siège social dc la compagnie est 895, rue St-Vàllier ouest, Québec, district judiciaire dc Québec././\u2022 sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Albert Gagnon.37391-0 2740-1970 Tapis Québécois inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date thc 25th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Lamontagnc, manager, 6965, 8lh Avenue East, Charlesbourg, Jean-Paul Gariépy, 395 des Peupliers West, and Roland Lavcrdière, 142 des Chênes West, the latter two traders of Quebec, for the following purposes: To manufacture and deal in carpets and oilcloths, under sc name of \"Tapis Québécois inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 1,000 common shares of S10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of thc company is at 895 St-Vallier Street West, Québec, judicial district of Québec.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 2740-1970 Trivil inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, cpi'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il :i accordé des lettres patentes, en date du 2e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Pierre Villeneuve, homme d'affaires, 470, boulevard St-Cyrillc ouest, Pierre Martin, avocat, 205, des Lilas ouest, tous deux de Québec, et Bernard Paré, avocat stagiaire, 4300, 4c Avenue est, Charlesbourg, pour les objets suivants: Agir comme agence de personnel dans toutes ses spécialités, sous le nom de « Trivil inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.I.e siège social de la compagnie est 764, St-Joseph est, Québec, district judiciaire de Québec.Usons-ministre des instilulioiis financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 3830-1970 Trivil inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 2nd day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Villeneuve, businessman, 470 St-Cyrillc Boulevard West, Pierre Martin, advocate, 265 ties Lilas West, both of Québec, and Bernard Paré, articled lawyer, 4300, 4 th Avenue East, Charlesbourg, for the following purposes: To act as a personnel agency in ull its specialties, under thc name of \"Trivil inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 764 St-.Ioscph East, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391 3830-1970 Turf Master Corporation Inc.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de septembre 1970, constituant en corporation: Marcel Turgcon, avocat, 42, de l'Hôpital, borelleville, Elisabeth Poulin, secrétaire, fille majeure, 580, St-Cyrillc ouest, Québec, et Jean Côté, journaliste, 31, Cavanagh, Repentigny, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs, imprimeurs, graveurs, relieurs et autres commerces semblables, sous le nom de « Turf Master Corporation b'c., avec un capital total de §40,000, divisé en 100 actions ordinaires de §100 chacune.Turf Master Corporation Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Turgcon, advocate, 42 de l'Hôpital, Lorettevillc, Elisabeth Poulin, secretary, spinster of the full age of majority, 580 St-Cyrillc West, Québec, and Jean Côté, journalist, 31 Cavanagh, Repentigny, for the following purposes: To carry on business as publishers, printers, engravers, bookbinders and other similar businesses, under the name of \"Turf Master Corporation Inc.\", with a total capital stock of §40,000, divided into 400 common shares of §100 each. 0852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n\" i8 1a; siège social de la compagnie est 5S0, St-Cyrille ouest, Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-minislre des inslilnlious financières, compagnies cl cooperalires, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 398G-1970 Bernard Turgcon inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour dc septembre 1970, constituant en corporation: Irwin Miller, 3050, Brighton, Montréal, Abraham Gtirmun, 80, Hollliani Rond, Hampstead, et Stephen Marcovitch, 2G0, Alexis-Ninon, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de systèmes contre la poussière, pour la purification cl l'assainissement de l'air, sous le nom de « Bernard Turgcon inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et en 3.000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des inslilnlious financières, compagnies cl coopérai ives, Ls-Philippe Bouchard.37391-0 4071-1970 The head office of the company is at .\">s() St.Cyrille West, Québec, judicial district of Quebec.Ls-PiHUPPE Bouchard.Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérait;,*.37391 39Mi.l97o Bernard Turgcon inc.Notice is given that under Fart I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17lli day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions.Com.panics and Cooperatives, incorporating: Irwin Miller, 3050 Brighton, Montreal, Abraham Cur-man, 80 Hollham Road, Hampstead, and Stephen Marcovitch, 200 Alexis-Nihon, Saint-Lament, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in dust, prevention, air-purifying and cleansing systems, under the name of \"Bernard Turgcon inc.\", with a total capital slock of $40.(1110.divided into 1,000 common shares of S10 each and into 3,000 preferred shares of $10 each.Thc head oflicc of thc company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperalires.37391 4071-1970 Tyncvale Construction Inc.Le ministre des instilulioiis financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du Se jour de juin 1970, constituant en coqwration: Irving Halpcrin, 5609, chemin de la Reine-Marie, Hampstead, Daniel Morris, 0105, avenue Notrc-Damc-dc-Gracc, tous deux avocats, Georgette Lavoic, fille majeure, 2860, avenue Granby, tous deux de Montréal, et Madeleine Mueller, épouse dc Julian Itiivcn, 2345, Bord-du-Lac, Saint-Raphaël-dc-rile-Bizard, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie d'immeuble, dc construction et de placement, sous le nom de « Tyncvalc Construction Inc.», avec un capital total dc S50.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 400 actions privilégiées dc S100 chacune Le siège social dc la compagnie est 6201, avenue dc la Côte Saint-Luc, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.37391 2946-1970 Unitronics Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22c jour de septembre 1970, constituant en corporation: Kenneth Harris, spécialiste en électronique, Barbara Powell, ménagère, épouse dudit Kenneth Harris, tous deux dc 539, Patricia, Greenfield Park, et Lawrence Diner, avocat, 4085 Harvard, Montréal, pour les objets suivants: Manufacturer des tubes, dispositifs et tous accessoires électroniques, en faire le commerce, sous le nom de « Unitronics Limited », avec un Tyncvalc Const ruction Inc.Notice is given that under Part I of llie Companies Act, letters patent, bearing dale Ihe Sth day of June, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irving Halpcrin, 5609 Queen Mary Road, Hampstead, Daniel Morris, 6165 Notre-Dame-dc-Grftcc Avenue, both advocates, Georgette Lavoic, lille majeure, 2860 Granby Avenue, both of Moid real, ami Madeleine Mueller, wife of Julian H liven, 2345 Bord-du-Lac, Saint-Rnphacl-do l'llc-lti-z.ard, the hitler two secretaries, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Tvncvale Construction Inc.', with a total capital stock of $50,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 400 preferred shares of SI00 each.Thc head office of the company is al_ 6201 Côte St-Luc Avenue, Montreal, judicial ilislricl of Montreal.Ls-Philippe Bouchard.Deputy Minister of Financial Instilulioiis.Companies and Coopérai ins.37391-0 2946-1970 Unitronics Limited Notice is given that under Part I of Ihe Companies Act, letters patent, bearing dab Ihe 22nd day of September, 1970, have been i isued by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, incorporating: Kenneth Harris, electronics specialist, Barbara Powell, housewife, wife of the said Kenneth Harris both of 539 Patricia, Greenfield Park, and Lawrence Diner, advocate, 4085 Harvard, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in electronic lulics.devices and all accessories, under the name ol \"Unitronics Limited\", with a total capital .-lock QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November''28, 1070, Vol.102, No.1,8 6853 capital total dc 840,000, divisé en 200 actions ordinaires de S100 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.I.c siège social de la compagnie est à Montréal, ilislricl judiciaire de Montréal.l.e sous-minislre associé des institutions financières, compagnies et coopérai ives, J.-Albert Gagnon*.37391 4132-1970 \\ mi Clasov Corporation I.c ministre dçs institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de juillet 1970, constituant en corporation: Peter R.D.MacKell, 3470, Stanley, .lames (;.Wright, 3164, The Boulevard, tous deux de MonIréal, et Michael P.Carroll, 254, avenue Metcalfe, Westmount, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de construction, sous le nom dc « Von Glasow Corporation », avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.l.e siège social dc la compagnie est à Sutton, ilislricl judiciaire dc Bedford./.c sous-ministre associé des instilulioiis financières, compagnies et coopératives, J.-Aluert Gagnon.37391 2976-1970 AI.Yamada Enterprises Ltd.l.e ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de In première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de juillet 1970, constituant en corporation: Moc Moscovitch, 6077, Wilderton, J.Roy Holfmnn, 5615, Pinedalc, tous deux de Montréal, et Michael Marchand, 5791, Mclling, Côte Saint-Luc, buis trois avocats, pour les objets suivants: Paire affaires dans la construction, l'entretien, l'amélioration ou la réparation d'édifices et dc maisons, sous le nom de « M.Yamada Enterprises Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune cl 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.l.e .-iège social dc la compagnie est 8937, rue Saiiil-Urbain, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe bouchahi).37391 3019-1970 Zcrcam Productions Limited Les productions Zcrcam limitée j.e ministre des institutions financières, compagnie, et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de septembre 1970, constituant en corporation : Donald Newton Byers, 604 avenue Clarke, Paul Frederick Dingle, 528, avenue Mount Pleasant, tous deux de Westmount, et Frederick William Bcnn, 3300, Glcncoe, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: S établir photographes et faire la reproduction de photos; s'établir artistes et graphistes, sous le nom de « Zercam Productions Limited \u2014 Les productions Zcrcam limitée», avec un capital of S40.000, divided into 200 common shares of S100 each and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial \u2022 Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 4132-1970 Von Glasow Corporation Notice is given that under Part I of thc Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of July, 1970, have been issued by the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Peter R.D.MacKell, 3470 Stanley, James G.Wright, 3164 Thc Boulevard, both of Montreal, and Michael P.Carroll, 254 Metcalfe Avenue, Westmount, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a construction company, under the name of \"Von Glasow Corporation\", with a total capital stock of S40,00(), divided into 10,000 common shares of thc par value of SI each and 30,000 preferred shares of thc par value of 81 each.The head office of thc company is at Sutton, judicial district of Bedford.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.37391-0 2976-1970 M.Yumada Enterprises Lid.Notice is given that under Part I of thc Companies Act, letters patent, bearing date the 13lh day of July, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Moc Moscovitch, 6077 Wilderton, J.Roy Hoffman, 5615 Pinedale, both of Montreal, and Michael Marchand, 5791 Mclling, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: Building or household construction, maintenance, improvement or repair, under the name of \"M.Yamada Enterprises Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of 81 each.Thc head office of the company is at S937 St.Urbain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instilulioiis, Companies and Cooperatives.37391-0 3019-1970 Zercam Productions Limited Les productions Zercam limitée Notice is given that under Part I of thc Companies Act, letters patent, bearing date thc 14lh day of September, 1970, have been issued by thc Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Donald Newton Byers, 604 Clarke Avenue, Paul Frederick Dingle, 528 Mount Pleasant Avenue, both of Westmount, and Frederick William Bcnn, 3300 Glcncoc, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of photographers and reproducers of pictures and to act as artists and commercial artists, under thc name of \"Zercam Productions Limited \u2014 Les productions Zcrcam 6854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° A8 divisé en -1,000 iiclions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, J.-Aldert Gagnon.37391 3998-1970 limitée\", with a capital stock divided into 4,000 common shares without par value.The head office of thc company is at Montreal judicial district of Montreal.J.-Albert Gagnon, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37391-0 399S-1970 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent Centre Paroissial Ste-Jeanne d'Arc Avis est donné qu'en vertu de l'article 19 du chapitre 304 des Statuts refondus de Québec, 1964, il a été accorde par le lieutenant-gouverneur île la province, des lettres patentes supplémentaires en date du 19 octobre 1970, à la corporation « Centre Paroissial Stc-Jeanne d'Arc», modifiant les dispositions de ses lettres patentes.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3741 l-o 9-63 Centre Paroissial Ste-Jeanne d'Arc Notice is given that in accordance with seel ion 19 of Chapter 304 of the Revised Statutes cf Québec, 1964, the Lieutenant-Governor of the Province granted supplementary letters paient on October 19, 1970 to the corporation \"Centre Paroissial Stc-Jeanne d'Arc\", modifying the pro-visions of its letters patent.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalires.37411 «1-63 Arrêtés en Conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4217 Québec, le 11 novembre 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.concernant une modification au règlement adopté en vertu dc lu Loi de l'Habitation familiale (1964 S.R.Q., chapitre 110 et amendements).Attendu Qu'en vertu dc l'article 75 de sa Loi, la Société d'habitation du Québec est chargée de l'exécution de la Loi dc l'Habitation familiale; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 dc la Loi de l'Habitation familiale, la Société peut faire îles règlements pour déterminer les conditions auxquelles les avantages dc cette loi sont accordés; ATTENDU qui: ces règlements doivent recevoir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et être publiés dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu que la Société a, par son règlement numéro 7, modifié le règlement concernant l'application de la Loi de l'Habitation familiale pour prévoir que les conditions d'éligibilité doivent être acceptables à la Société et pour prévoir que les projets d'habitation en copropriété approuvés par ladite Société rendent ses propriétaires éli-giblcs aux avantages de ladite Loi dc l'Habitation familiale; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement numéro 7 de la Société d'habitation du Québec.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le règlement numéro 7 dc la Société d'habitation du Québec, modifiant le règlement concernant l'application dc la Loi de l'Habitation familiale, est approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Chouinard.Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 4217 Québec, November 11, 1!)7().Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an amendment to the regulation adopted pursuant to the Family Housing Act (1964, R.S.Q., Chapter 110 and amendments.) Whereas pursuant to article 75 of its Act, the Québec Housing Corporation is entrusted with the carrying out of the Family Housing Act; Whereas pursuant to article 12 of the Family Housing Act, the Corporation may make regulations to determine the conditions upon which the advantages of this Act arc granted; Whereas these regulations must be improved by the Lieutenant-Governor in Council and lie published in the Québec Official Gazelle.Whereas the Corporation has, by its regulation number 7, amended the regulation concerning thc application of the Family Housing Act in order that the conditions of admissibility be acceptable to the Corporation and in order that thc joint ownership housing projects approved by the said Corporation render its proprietors admissible for the advantages of the said Family Housing Act; Whereas it is expedient to approve this regulation number 7 of the Quebec Housing Corporation.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Municipal Affairs, that follow : Regulation number 7 of the Québec Housing Corporation amending the regulation concerning the application of thc Family Housing Act.is approved.Julien Chouinard.Clerk of Ihe Executive Council. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6855 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC Assemblée du 24 septembre 1970 Résolution numéro 3325 Règlement numéro 7\u2014Modification au Règlement concernant l'application dc la Loi dc l'Habitation familiale.Attendu que la Société petit faire des règlements pour déterminer les conditions auxquelles les avantages de la Loi de l'Habitation familiale sont accordées; Attendu qu'il y a lieu dc modifier le règlement concernant l'application dc la Loi de l'Habitation familiale pour prévoir son application aux habitations en copropriété et faciliter l'approbation d'unités unifamilialc, bifamilialc, en rangée cl autres; Kx conséquence, il est résolu qu'un règlement portant le numéro 7, soit adopté; et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 1.l.e paragraphe b) de l'article 2 de la Section II dudit règlement est remplacé par le suivant: l'expression «habitation nouvelle» s'applique: 1.à une maison d'habitation unifamilialc ou liifaniiliale isolée ou jumelée, dont la construction a été commencée après le premier juin 19G0; ii.à une habitation en rangée commencée après le premier juin 1966, préalablement approuvée conformément aux règlements alors en rigueur; iii.aux habitations comprises dans un projet de cinq unités d'habitation ou plus commencé après le deux mai 1970; iv.aux habitations en copropriété construites aînés le quinze janvier 1948.» 2.l.e dernier alinéa dc l'article 3 de la Section III dudit règlement est remplacé par le suivant: « Les dispositions concernant l'éligibilité s'appliquent à toutes les maisons dont la construction a été commencée après le trente septembre 1967 cl aux habitations en copropriété.» 3.l.e paragraphe (c) de l'article 5 de la Section I\\ dudit règlement est remplacé par le suivant: ' La somme des prêts ainsi obtenus ne doit pas excéder 814,000 pour les maisons tmifamiliales isolées, jumelées, en rangée ou en copropriété, et $20,(100 pour les maisons bifamiliales isolées ou jumelées.» 4.l.e paragraphe d) de l'article 5 de la Section 1\\ dudit règlement est remplacé par le suivant: « Le coût dc construction ou le prix d'acquisition de la nouvelle habitation, y compris le coul du terrain ou autres améliorations, ne doit pas dépasser 817,000 pour les maisons unifamilialc-, isolées, jumelées, en rangée ou en copropriété, et 825,000 pour les maisons bifamiliales isolées ou jumelées.» 5.L'article 8 de la Section V dudit règlement modifié par le règlement numéro 3 du 17 février I90S, est remplacé par le suivant: « S.Pour toute construction commencée après e deuxième jour dc mai mil neuf centsoixante-dix, le terrain, la construction, les matériaux, les plans et la localisation de toute habitation nouvelle doivent être acceptables à la Société.» 0- L'article 10 «le la Section V dudit règlement, modifié par le règlement numéro 3 du 17 février 1968 et par le règlement numéro 6 du 2 mai 1970, EXTRACT FROM THE MINUTES OF A MEETING OF THF QUÉBEC HOUSING CORPORATION Meeting of September 24, 1970 Resolution number3325 Regulation number 7 \u2014 Amendments to the regulation concerning the application of the Family Housing Act.WllEREAS the Corporation may make regulations to determine Ihe conditions upon which the advantages of the Family Housing Act arc granted; Whereas it is expedient to amend the regular lion concerning the application of the Family Housing Act to provide for its application to joint ownership dwellings and facilitate the approval of one family, two family dwelling units, in rows and otherwise; Therefore, it is resolved that a regulation bearing number 7 be adopted; and that the following be statuted and decreed by this regulation: 1.Paragraph (6) of article 2 of section II of the said regulation is replaced by the following: \"(b) the expression \"new dwelling\" applies: 1.to a one family or two family isolated or duplex dwelling, the construction of which was started after the first day of June, 1960; ii.to a dwelling in rows started after the first day of June, I960, approved beforehand in conformity with tlic regulations at that time in force; iii.to dwellings included in a five dwelling or more housing project unit started after the second day of May, 1970; iv.to joint ownership dwellings built after the fifteenth day of January, 1948.\" 2.The last paragraph of article 3 of Section III of the said regulation is replaced by the following: \"The provisions concerning admissibility apply to all houses thc construction of which was started after the thirtieth day of September, 1907, and to joint ownership dwellings.\" 3.Paragraph (c) of article 5 of Section IV of the said regulation is replaced by the following: \"Thc sum of the loans thus obtained must not exceed 814,000 for one family isolated, duplex houses, in rows or joint ownership houses, and 820,000 for two family isolated or duplex houses.\" 4.Paragraph (d) of article 5 of Section IV of the said regulation is replaced by the following: \"The cost of construction or the acquisition price of the new dwelling, including the cost of the land and other improvements, must not.pass SI7,000for one family, isolated, duplex, houses, in rows or joint ownership houses, and 825,000 for two family isolated or duplex houses.\" 5.Article 8 of Section V of the said regulation amended by regulation number 3 of February 17, 1968, is replaced by the following: \"8.For any constructions started after thc second day of May, one thousand nine hundred and seventy, thc lands, constructions, materials, projects and localities of all new dwellings must be acceptable to the Corporation.\" 6.Article 10 of Section V of the said regulation amended by regulation number 3 of February 17, 1968 and by regulation number 6 of May 2, 1970, CS5C GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,S est de nouveau modifié en abrogeant le premier et le dernier alinéa.7.Ledit règlement est modifié en insérant, après l'article 10, la section suivante: Section Va Dispositions concernant l'habitation en copropriété.10 a) Tout projet d'habitation en copropriété mis en chantier depuis le deux mai 1070, doit pour rendre les acquéreurs éligiblcs aux bénéfices de la Loi : 1.cire au préalable approuvé par la Société d'habitation du Québec; 2.ne comprendre aucun logement au sous-sol pour fin de vente; 3.compter, pour 50% des logements au moins deux (2) chambres à coucher fermées.Les logements à une seule pièce ou ne comprenant qu'une seule chambre à coucher fermée Ile rendent, pas les propriétaires éligiblcs aux bénéfices de lu Loi.Toutefois, la Société d'habitation du Québec peut reconnaître certaines personnes éligiblcs nu bénéfices de la Loi demeurant dans un appartement d'une seule pièce ou ne comprenant qu'une seule chambre à coucher fermée dans des cas tels que personnes âgées, veuves.10 6) Les habitations en copropriété construites entre le quinze janvier 1948 et le deux mai 1970, doivent satisfaire à toutes les conditions déterminées à l'article 10 a).Toutefois, un tel projet, quoique comportant un ou des logements au sous-sol pour fin dc vente, peut être accepté et les propriétaires éligiblcs aux benefices de la Loi, sauf ceux des logements au sous-sol.10 c) L'éligibilité de tout bénéficiaire devra être vérifiée et établie à tous les cinq ans et son éligibilité devra rencontrer les conditions alors en vigueur sous peine de déchéance.Daté le 16 octobre 1970.Certifié copie conforme.Le secrétaire, 37393-0 Coxiiai) Delisle.is again amended by abrogating the first and last paragraphs.7.The said regulation is amended by adding after article 10, the following section: Section' Va Provisions concerning joint ownership dwellings.10(a) All joint ownership housing projects lay out since thc second day of May, 1970.must, t*i render the purchasers admissible for the benefits of thc Act : 1.beforehand be approved by the Québec Housing Corporation; 2.not include an apartment in the basement for selling purposes; 3.include, for 50% of the apartments at least two (2) closed bedrooms.Single room upurlmcnls or apartments including a single closed bedroom do not render the proprietors admissible for Ihe benefits of the Act.However, the Québec Housing Corporation may acknowledge the admissibility of certain people for the benefits of the Act, residing in a single room apartment or including a single closed bedroom, in such cases as for the aged and widows.10(fc) Joint ownership dwellings buill between the fifteenth day of January, 1948 and Ihe second day of May, 1970, must answer to all Ihe conditions decided upon in article 10 (a).However, such a project, although it may include one or several apartments in the basement for selling purposes, may be accepted and the proprietors admissible for the benefits of the Act, save Lliosc residing in the basement apartments.10(c) The admissibility of any beneficiary shall be verified and established every five years and his admissibility shall have to meet the conditions then in force under pain of forfeiture.Dated on October 16, 1070.Certified true copy.Conrad Delisle, 37393 Secretary.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 416S Québec, le 11 novembre 1970.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'adoption du règlement numéro cinq (5) de la Commission de Police du Québec relatif aux uniformes et insignes qui peuvent être portés par les policiers municipaux.Attendu que la Commission de Police du Québec peut, par règlement, determiner les caractéristiques des uniformes et insignes qui peuvent être portés par les policiers municipaux suivant l'alinéa c de l'article 17 de la Loi de Police (chapitre 17 des lois de 196S); Attendu Qu'il est opportun de déterminer les caractéristiques des uniformes et insignes qui peuvent être portés par les policiers municipaux; Attendu que les règlements de la Commission dc Police sont subordonnés à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; Il est ordonné, sur la proposition du ministre dc la Justice: Que sous l'autorité de l'article 18 dc la Loi de Police, le règlement numéro cinq (5) relatif aux uniformes et insignes qui peuvent être portés par Order in Council Executive Council Chamber Number 4168 Québec, November 11, 1979.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the passing of by-law number five (5) of the Québec Police Commission relating to thc uniforms and badges which may be worn by municipal policemen.Whereas thc Québec Police Commission may, by by-law, determine the characteristics of the uniforms and badges which may be worn by municipal policemen in accordance with paragraph c of section 17 of the Police Act (chapter 17 of the statutes of 196S) ; Whereas it is ex])cdicnt to determine the characteristics of the uniforms and badges which may be worn by municipal policemen: Whereas the by-laws of thc Police Commission are subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council; It is ordered, upon the recommendation of thc Minister of Justice: That under the authority of section IS ol the Police Act, by-law number five (5) relating to the uniforms and badges which may be worn QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.48 6857 les policiers municipaux soit adopte et entre en vigueur le jour de sa publication duns lu Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Chouinard.Règlement numéro 5 Relatif aux uniformes des corps de police municipaux l.a Commission de Police du Quebec, en exécution îles pouvoirs qui lui sont conférés pur lu |.ni (li- Police, décrète ce qui suit: 1° l.e présent règlement est connu sous le nom de Règlement numéro 5 » relatif aux uniformes îles coips «le police municipaux.\u2022J3 Dans le présent règlement, à inoins «pie le contexte n'indique un sens différent, les expression- el mots suivants signifient: m Corps de police municipal: Tout corps de police établi par une ou plusieurs corpora lions municipales ou par le Conseil d'une communauté urbaine ou régionale./.i Officier: Tous les membres d'un corps de police ayant le grade de lieutenant ou un grade supérieur à celui de lieutenant.r s tus-officier: Tous les membres d'un corps dc police qui ont nu grade autre que celui attribué aux ollicicrs.(/) Constable: Tout membre d'un corps de police n'ayant aucun grade particulier mais ne comprenant pas l'aspiraul-policier et le cadet.n Aspirant-policier: Tout membre d'un corps de police municipal qui n'a pas encore complété sa période d'entraînement et de probation./) Ciulel: Toute personne qui n'a pas encore complété sa période d'entraînement et de probation dans un corps de ]M>lice et qui n'a pus attcintl'ageprescrit parles règlements de la Commission dc Police du Québec |M)iir devenir constable duns un corps «le police municipal.g) Uniforme: l.a tenue vestimentaire des membres d'un corps de police.h) Insigne de corps: Les insignes servant à identifier un corps dc police.0 BNQ: I.e Bureau de Normalisation du Québec du ministère de l'Industrie et du Commerce.\u2022I Les ollicicrs, sous-officiers et policiers de sexe niaxcutin doivent, selon le cas, revêtir, dan- l'exercice de leurs fonctions, l'uniforme réglementaire ci-après décrit à moins qu'il ne s agisse de l'accomplissement d'un travail dans une section spécialisée mentionnée à l'article 6 au présent règlement.Ile plus, le directeur d'un corps de police, selon qu'il le jugera à propos, pourra décréter que | exercice de certaines fonctions ou l'accomplissement de certaines tâche- par les membres (I un corps de police se fera sans le port dc I uniforme.by municipal policemen be passed and come into force on the day of its publication in the Québec Official Gazelle.Julien Chouinard, Cleric of the Executive Council.By-law number 5 Relating to the uniforms of the municipal police forces The Québec Police Commission, in the carrying out of the powers conferred upon it by thc Police Act, enacts as follows: 1.This by-law is known as \"By-law number 5\" relating to the uniforms of municipal indice-forces.2.In this by-law, unless the context indicates a different meaning, thc following expressions and words mean: (a) Municipal Police Force: Any police force established by one or more municipal corporation- or by the Council of an urban or regional community.(6) Officer: All the members of a police force having the rank of lieutenant or a higher rank than that of lieutenant.(c) Junior officer: All the members of a police force who have a rank other than that assigned to officers.((/) Constable: Any member of a police force who has no particular rank but not including a police candidate and a cadet.(c) Police candidate: Any member of a municipal police force who has not yet completed his training and probation period.(/) Cadet: Any person who has not yet completed his training and probation period in a police force and who has not reached thc age prescribed by the regulations of the Québec Police Commission to become a constable in a municipal police force ig) Uniform: The dress uniform of thc members of any police force (//) Badges of the police forces: The badges used to identify a police force.(i) BNQ: The Québec Normalization Bureau of the Department of Industry and Commerce.3.The officers, junior officers and policemen of the masculine sex must, as thc case may be, wear, in the performance of their duties, the regulation uniform hereinafter described except when they do work in a specialized section mentioned in section 6 of this by-law.Moreover, the Director of a police force, as he sees fit, may order that the performance of certain duties or the carrying out of certain tasks by the members of a police force will be done without wearing the uniform. C858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' minée, n° 18 4° I,'uniforme réglementaire pour les membres des corps de police est le suivant: a) La tunique: a) Pour les officiers: La tunique est munie de deux poches dc poitrine extérieures et de deux poches soufflet dc ceification.(b) For junior officers, constables, police candidates and cadets: Thc trousers with a \"Québec\" blue strip on the outside scam of each side of the trousers must be made in accordance with specification number 7411-126 of the BNQ and as it appears in design number 1 accompanying the said specification.The colour of thc strip is in accordance with specification number 9901-901 of thc BNQ.(C) Fabric: (a) For the summer season: Thc optional tunic and the compulsory trousers for all members of a police force are made ol tropical fabric consisting of wool and polyester fibre, the whole as is more fully described in specification number 7045-571 of the BNQ.(6) For the winter season: The tunic and trousers for all members of a police force arc made of twilled serge fabric consisting of polyester and wool fibre, the whole as is more fully described in specification number 7045-550 of thc BNQ.(c) Colour of fabric: The fabric must be navy blue in colour in accordance with thc sample furnished by the BNQ.(d) Uniform for Ihe summer season: The trousers made of the tropical fabric above described forms part of the regulation uniform for thc summer season and is compulsory for all members of a police force, but the tunic made of the tropical fabric above described^ optional for the summer season for each police force QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.MS 6859 ])) |!olcle pour ceinture de tunique fabriquee de tissu pour tous les membres d'un corps de police: l.a boucle doit être de forme rectangulaire et {Ire Minnie de deux ardillons et avoir un fini brillant de couleur jaune semblable à celui des boulons de la tunique, le tout tel que plus ample-incnl décrit dans la spécification numéro 7940-810 du I1NQ.E) Ceinture de cuir: Deux ceintures dc cuir noir font partie dc l'uniforme réglementaire pour tous les membres d'un corps de pllicc.L'une d'une largeur dc un pouce cl trois-quarts il\" :,| i est utilisée pour porter le pantalon alors qu'un membre d'un corps dc police porte la tunique.L'an Ire d'une largeur de deux pouces cl tin-quarl est utilisée pour porter le pantalon el y suspendre les accessoires lorsqu'un membre d'un corps de police ne porte pas la tunique.Lorsqu'un membre d'un corps de police porte la tunique, cette ceinture plus large est portée à l'extérieur de la tunique pour y suspendre les accessoires; Les boucles (le ces ceintures sont fabriquées conformément à la spécification numéro 7940-815 ilu BNQ.Ces ceintures sont fabriquées suivant la spécification numéro 7453-105 du BNQ.F) Képi d'été: h) Polir Ions les membres d'un corps de police: Le képi d'été muni d'une visière est fabriqué (1*1111 tissu de base bleu et la couronne est bordée (l'une nervure bleue, le tout conformément à la specification numéro 7456-101 du BNQ et tel qu'il appert aux dessins numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de Indite spécification.(i) Képi d'hiver: a) Polir lotis les membres d'un corps de police: Le képi d'hiver muni d'une visière est fabriqué d'un tissu dc base bleu et la couronne est bordée d'une nervure bleue, le tout conformément à la spécification numéro 7456-102 du BNQ et tel qu'il appert aux dessins numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de ladite spécification, H) Chemise: Pour tous les membres du corps de police, la cliçmisc est fabriquée d'un tissu dc couleur bleue conforme à la spécification numéro 7031-272 du BNQ.Cet le chemise munie dc deux poches de poitrine duit être fabriquée conformément à la spécification numéro 7455-116 du BNQ et tel qu'il appert aux dessins numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de ladite spécification.1) Cravate: La cravate à noeud tout fait est nouée de façon permanente et doit être fabriquée conformément à la spécification numéro 7454-104 du BNQ et tel qu'il appert au dessin numéro 1 accompagnant ladite spécification.< 'cl te cravate est de couleur bleue et fabriquée du tissu décrit à ladite spécification.Des échantillons du tissu sont conservés au BNQ.(D) Buckle for tunic belt made of a material for all members of a police force: The buckle must be rectangular in shape and be provided with two catches and have a shiny yellow finish similar to that of the tunic buttons, the whole as is more fully described in specification number 7940-810 of the BNQ.(E) Leather belt: Two black leather belts form part of the regulation uniform for all members of a police force.One having a width of one and three-quarter inches (1\" is used to support the trousers when a member of a police force wears the tunic.The other having a width of two and one-quarter (2\" inches is used to support the trousers and to suspend the accessories thereof when a member of a police force does not wear the tunic.When a member of a police force wears the tunic, such larger belt is worn over the tunic to suspend the accessories thereof.\\ The buckles of such belts arc made in accordance with specification number 7940-815 of the BNQ.Such belts are made in accordance with specification number 7453-105 of the BNQ.(F) Summer kepi: (a) For all members of a police force: The summer kepi provided with a visor is made of basic blue fabric and the crown is bordered with blue braiding, the whole in accordance with specification number 7456-101 of thc BNQ and as it appears in designs numbers 1, 2, 3, 4 and 5 of the said specification.(G) Winter kepi: a) For all members of a police force: The winter kepi provided with a visor is made of basic blue fabric and the crown is bordered with blue braiding, the whole in accordance with specification number 7456-102 of the BNQ and as it appears in designs numbers 1, 2, 3, 4 and 5 of the said specification.(H) Shirt: For all members of a police force, the shirt is made of a blue coloured fabric in accordance with specification number 7031-272 of the BNQ.Such shirt provided with two breast pockets must be made in accordance with specification number 7455-116 of the BNQ and as it appears in designs numbers 1, 2, 3, 4 and 5 of the said specification.(I) Necktie: Thc necktie with a permanent knot must be made in accordance with specification number 7454-104 of the BNQ and as it appears in design number 1 accompanying the said specification.Such necktie is blue in colour and made with the fabric described in the said specification.Samples of the fabric are kept at the BNQ. 6860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n\" 1,.S j) Paletot: A.Paletot trois saisons: a) Pour les officiers: Le paletot est fait «l'un tissu dc base dc couleur bleue, «le coupe semi-ajustée, fabriqué conformément à la spécification numéro 7412-215 du BNQ.b) Pour les sous-officiers, constables, aspirants-policiers et cadets: l,c paletot fait d'un tissu de base bleu marin imperméable est muni d'une doublure en piqué amovible cl doit être fabriqué conformément à la spécification numéro 7412-145 du BNQ.B.Paletot saison chaude: a) Pour les officiers: l.e paletot fait d'un tissu de base en gabardine bleu marin, de coupe ample, doit être fabriqué conformément à la spécification numéro 7412-145 du BNQ.b) Pour les sous-officiers, constables, aspirants-policiers el cadets: Le paletot imperméable est réversible et offre d'un côté une surface imperméable de couleur noire et de l'autre une surface imperméable de couleur orange fluorescent, et doit être fabriqué conformément à la spécification numéro 7413-171 du BNQ.C.Pour le plus grand confort des officiers engagés dans l'opération, ces derniers pourront, suivant ce qui sera décidé par le directeur île chaque corps de police, revêtir, selon la saison, les paletots ci-haut décrits pour les sous-officiers, constables, aspirants-policiers et cadets.K) Les routons: Les boutons de diverses grandeur utilisés sur la tunique, les paletots trois saisons et le képi doivent être fabriqués conformément à la spécification numéro 7940-235 du BNQ et tel qu'il appert au dessin numéro I accompagnant, ladite spécification.Chaque bouton porte en relief la fleur de lys (pointillés et avec nervure) el ainsi que le mol « Québec » au centre, et le mol « Police » est inscrit au bas du bouton et centré, le tout tel qu'il appert au dessin numéro 1 dc la spécification numéro 7940-235 du BNQ.L) Soulier: Le soulier est.fabriqué de cuir dc veau (vcal skin) de première qualité présentant un fini lisse et brillant de couleur noire, le tout conformément à la spécification numéro 7511-120 du BNQ et tel qu'il appert aux dessins numéros 1,2 cl 3 dc ladite spécification.M) Bottine: La bottine est fabriquée de cuir de veau (veal skin) de première qualité présentant un fini lisse et brillant de couleur noire, le lout conformément à la spécification numéro 7511-220 du BNQ et tel qu'il appert aux dessins numéros 1, 2 et 3 dc ladite spécification.N) Chaussette: a) Pour la saison chaude: Ce vêtement est fabriqué d'un lissu irrétrécissable de couleur noire, le tout tel que plus amplement décrit à la spécification numéro 7451-311 du BNQ.(.1) Oveucoat; A.Three season overcoat: (a) For officers: The overcoat is made of basic blue fabric, with a semi-fitted cut in accordance with speeifi.cation number 7412-215 of the BNQ.(b) For junior officers, constables, police candidates and cadets: Thc overcoat made of waterproof basic navy blue fabric has a removable quilted lining and must be made in accordance with spécification number 7412-145 of the BNQ.B.Summer season coat: (a) For officers: The coal made of basic navy blue gabardine fabric with a loose cut, must be made in accordance with specification number 7412-145 of the BNQ.(b) For junior officers, constables, police candidates and cadets: Thc waterproof coat is reversible and has black waterproof fabric on one side and fluorescent orange fabric on the other, and must be made in accordance with specification number 7413-171 of the BNQ.C.For the greater comfort of thc officers on duty, they may, depending on what may he decided by the director of each police force, wear, according to season, thc above-described overcoats or coats of the junior officers, eon-tables, police candidates and cadets.(K) Buttons: The buttons of various sizes used on tunics, three season overcoats and kepis must be made in accordance with specification number 79IU-235 of the BNQ as it appears in design number accompanying the said specification.Bach button has in relief a \"fleur-de-lis\" (stippled with nervure) und the word \"Québec\" in the center and the word \"Police\" centered in thc lower part, the whole as it appears in design number 1 of specification number 7940-235 of the BNQ.(L) Shoes: The shoes arc made of first quality veal -bin with u smooth and glossy black finish, the whole in accordance with specification number 7ÔII-126 of the BNQ and as it appears in designs numbers 1, 2 and 3 of thc said specification.(M) Boots: The boots arc made of first quality veal skin with a smooth and glossy black finish the whole in accordance with specification number 7511-220 of the BNQ and as it appears in designs numbers 1, 2 and 3 of the said specification.(N) Socks: (a) For the summer season: This article of clothing is made of unshrinkable black fabric, thc whole as is more fulby described in specification number 7451-311 of the BNQ. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6861 li i Pour leu saisons froides: ( c vêlement esl.fabriqué d'un tissu irrétrécissable île couleur noire, le tout tel que plus ainple-iiicnl décrit à lu spécification numéro 7451-315 du BNQ.()) l'ol I.AIII) l'Ol'Il SAISONS FROIDES: I.r foulard esl fabriqué de laine de teinte bleu marin conformément à la spécification numéro 7454-221 du BNQct.au dessin numéro 1 dc ladite spécification .1') Accessoires: U'.s accessoires ci-bas décrits font partie de riiniforinc réglementaire des officiers, sous-officiers .1 policiers et doivent, selon le cas, ren-cnnlrcr les exigences minimales suivantes, mais le m.de de fabrication est laissé à la discrétion de eliaqilC corps de police.A.Cants: n) liants demi-saison: Ce gant esl fabriqué de cuir noir dc qualité et muni de boutons pressoirs./;) Gdnls d'hiver: Ce gant est fabriqué de cuir noir de qualité et muni de boulons pressoirs et fouré.I!.Mitaine: Les mitaines sont fabriquées de cuir noir cl doublées île fourrure de mouton ou d'un autre produit analogue C.Caoutchouc: Les caoutchoucs demi-saison sont fabriqués dc caoutchouc et nylon de teinte noire el munis d'une languette à l'arrière.11.ortant les numéros 415 ii 429 inclusivement émis le 26 mars 1970; Attendu qu'en vertu de l'alinéa «;«.» de l'ar-liclc '-'US dc la Loi des mines (13-14 Elizabeth IL chapitre 34), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les conditions des permis de recherche suivant l'article 144 de celte loi; Attendu Qu'en vertu dudit article 144, une société constituée en vertu des lois de la province peut faire réduire jusqu'à concurrence dc 75% pour la première année cl de 50% pour toute innée subséquente le montant dc la rente et le eoàl travaux requis si elle détient au moins cinq (5) permis contigus d'une superficie globale d'au moins 250,000 acres dans les districts électoraux de Itimouski.Malapédia, Matanc, Gaspé-n'onl.Guspé-Sud, Honavcnture et des Iles de la .Madeleine, l'Ile d'Anlicosti, le territoire d'Abitibi et le Nouveau-Québec; Attendu que les permis de recherche précités rouvrent une superficie totale dc 838,000 acres sur l'Ile d'Anlicosti.II.i 1st ordonne, en conséquence, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Qi k conformément à l'article 144 de la Loi des mines (13-14 Elizabeth II.chapitre 34), le montant de la rente et le coilt des travaux requis soient réduits jusqu'à concurrence de 75% pour In première année et de 50% pour toute année subsequence pour les permis de recherche 415 a 42'.i inclusivement accordés à Gamachc Exploration & Mining Co.Ltd.et couvrant une superficie de 838,000 acres; Qui: ce règlement ait force de loi à compter de sa publication dans la Gazelle officielle du Qufbec.Le greffier du Conseil exécutif, 37427-0 Julien Chouinaud.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 432S Québec, le 18 novembre 1970.Présent ; |,e Lieutenant-gouverneur en conseil.' ONcbrn'ant des corrections à l'arrêté en conseil numéro 3921 du 28 octobre 1970 \u2014 Modifications uu décret relatif à l'industrie du bois ouvré dans la région de Québec.8.These by-laws shall come into force three years after their publication in the Québec Official Gazelle and until such time the various police forces may benefit from the provisions of these by-laws to the extent that they will have to renew their uniforms.37420-o Order in Council Executive Council Chamber Number 4314 Québec, November IS, 1970.Present: the Lieutenant-Governor in Council.concerning the reduction in the amount of the rental and the cost of the required work \u2022 payable by the Gamachc Exploration Mining ( 'o.Ltd.Whereas the Ganuichc Exploration & Mining Co.Ltd.holds fifteen (15) exploration licences for petroleum and natural gas, that is licences bearing numbers 415 to 429 inclusively issued March 26, 1970; Whereas pursuant to paragraph \"c\" of section 268 of the Mining Act (13-14 Elizabeth II, chapter 34), the Lieutenant-Governor in Council may prescribe conditions respecting exploration licences pursuant to section 144 of this Act; Whereas pursuant to thc said section 144, a company incorporated under the laws of the Province may have reduced to the extent of 75% for the first year and 50% for each subsequent year the amount of the rental and the cost of the required work if it holds at least five (5) contiguous licences of a total area of at least 250,000 acres in Ihe electoral districts of Rimouski, Malapédia, Matanc, Gaspé-North, Gaspc-Soulh, Itonavcntiirc and the Magdalen Islands, the Island of Anticosti, the territory of Abitibi and New Québec; Whereas the aforementioned exploration licences cover a total area of 838,000 acres on the Island of Anticosti.It is ordered, therefore, on the recommendation of the Minister of Natural Resources: That, in accordance with section 144 of the Mining Act (13-14 Elizabeth II, chapter 34), thc amount of the rent und the cost of the work required be reduced to the extent of 75% for the first year and 50% for each subsequent year for exploration licences 415 to 429 inclusively granted to thc Gamuchc Exploration & Mining Co.Ltd.and covering an area of 838,000 acres; That this by-law carry force of law from and after the date of its publication in the Quebec Official Gazelle.Julien Chouinard, 37427 Clerk of Ihe Execulirc Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 4328 Québec.November 18, 1970.Present: The Lieutenant-Governor in Council.concerning corrections to Decree No.3921 of October 28, 1970, respecting the Woodworking Industry in the Québec region. 6S64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n° AS II est ordonne, sur lu proposition tic l'hono-rublc ministre du Travail et de lu Main-d'œuvre : Que l'arrêté en conseil numéro 3921 du 28 octobre 1970.concernant des modifications au décret numéro 2684 du 28 septembre 1967 et modifications, relatif à l'industrie du bois ouvré dans la région de Québec, soit corrigé dc la façon suivante: 1° Le mot « Montmngny» apparaissant à la fin dc l'article II (Champ d'application) doit se lire * Montmorency ».2° Le paragraphe 9.01 de l'article IX (Jours fériés chômés et payés) doit se lire de la façon suivante: « 9.01 Tout salarié doit recevoir une indemnité égale à une (1) journée de salaire au taux dc salaire minimum du présent décret pour les jours fériés suivants: Le premier jour de l'An, le 2 janvier, la Snint-.Ieun-lîaptiste, la Confédération, la fête du Travail, le jour dc Noël et le 26 décembre.» Le greffier du Conseil exécutif, 37478-0 Julien- Chouinard.It is ordered, upon thc recommendati.ni of the Honourable Minister of Labour and Man-power: That Decree No.3921 of October 28, 1970, concerning amendments to decree No.20s ! of September 28, 1967, and amendments, respecting the Woodworking Industry in thc Québec region, be corrected as follows: 1.\"Montmagny\", at the end of section \\\\ (Territorial Jurisdiction) should read \"Mont-morency\".2° Subsection 9.01 of Section IX (General holidays with pay) should read us follows: \"9.01 Every employee is entitled to one 1 full day's pay, at thc present decree's minimum rate, for each of the following general holidays: New Year's Day, January 2nd, St.John the llaptist Day, Canada Day, Labour Day, ( Jhrist-mas Day and December 26lh.\" Julien Chouinard, 37478-0 Clerk of the Executive Council.Compagnies dissoutes Companies Dissolved The Itecrcution and Parks Association of Quebec L'Association de la Récréation cl des Parcs du Québec \\x ministre îles institutions financières, compagnies et eoojiératives donne avis, qu'en vertu dc la Loi des compagnies, il n accepte l'abandon de charte de « The Recreation ami Parks Association of Québec\u2014 L'Associa lion dc la Récréation et des Parcs du Québec , constituée en corporation le 10 août 1965, à compter du 30 novembre 1970.Le directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.37391-0 2464-65 Association of Food Mcrchunts of Montreal Inc.Association «les Marchands d'Alimentation de Montréal inc.Le ministre tics institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la Loi , constituée en corporation le 11 août 1901, à compter du 30 novembre 1970./.c directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.37391-0 \u2022 13979-61 Crescent Land Corp.l.e ministre des institutions financières, compagnies el coopératives donne avis, qu'en vertu île la Loi des compagnies, el coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon dc charte de « Crescent Land Corp.constituée en corporation le 23 décem-lire 1959, à compter du 30 novembre 1970.l.e directeur du service des com pagaies, Rocn Rioux.37391-0 1 0983-59 Gcnstar Holdings Limited Le ministre des institutions financières, com-pagnics cl coopératives donne avis, qu'en vertu île la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon île charte de « Gcnstar Holdings Limited constituée m corporation le 21 octobre 1903, à compter du 30 novembre 1970.l.e directeur du service des compagnies, Rocn Run x.37391-0 -1069-63 l.a Vigie Le ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de clin rte de « Iai Vigie >\u2022, constituée en corporation le 6 mars 1959, à compter du 30 novembre 1970.l.e directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.37391.11416-59 Les Loisirs dc lu Vallée dc l'Or inc.Le ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu île la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon île charte dc « Les Loisirs de la Vallée de l'Or inc.constituée en corporation le 20 août 1962, à compter du 30 novembre 1970.I.c directeur du service des compagnies, Rocn Rioux.37391-0 13440-02 Maru ill Reulties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la Loi des compagnies, il a accepte l'abandon «le charte de « Marwill Realties Inc.», constituée en our un client, les notaires concernés doivent tenter de régler leur différend à l'amiable et, dc toute façon, ils ne doivent pas intenter une action en justice ou faire une réclamation quelconque sans avoir, au préalable, référé ce différend au Président dc In Chambre des Notaires.19.Le notaire ne doit surprendre la bonne foi île -i \u2022 confrères ou se rendre coupable d'abus de confiauce ou dc procédé déloyal dans ses rapports professionnels avec ses confrères.'(¦n ml deux notaires sont au dossier, représentant des intérêts adverses, l'un et l'nutre doivent s efforcer d'accommoder leur confrère dans ln mesure où les intérêts du client n'en souffriront |kis.Il ne doit pas entreprendre quelque négociation ou compromis directement avec la partie repré-MiiPc par l'autre notaire, sans prévenir ce confrere.20.Le notaire doit collaborer avec ses confrères et éviter toute concurrence déloyale à leur égard.H doit, sur demande d'un confrère dûment autorisé par le notaire, remettre les dossiers et documents appartenant à ce client.11.A Notary must not use for his own profit securities of which he has the custody.12.A Notary must execute with reasonable dispatch all matters that arc entrusted to him, and must organize his office efficiently so that his clients' business will not be retarded under the pretext of lack of lime, or shortage of clerical help, or other causes reflecting upon the efficiency of his office.13.A Notary must not retain for any undue length of lime files or documents belonging to clients.14.A Notary must not exert pressure nor use any fraudulent means lo compel anyone lo sign a deed or document.15.A Notary must refuse to lend his professional services to any transaction of a noturiously improper or sordid nature.CHAPTER TWO Dulles lo Ihe stale 10.It is a Notary's duty lo uphold law and order.He must refuse to give the character of authenticity to illegal or fraudulent acts.He must refrain from giving counsel directly or indirectly to those who would fraudulently avoid the payment of taxes, or commit, acts which would endanger the security of the State Chapter three Duties to his colleagues 17.A Notary must have a sense of profound professional solidarity.His attitude to his Colleagues must be one of utmost courtesy and integrity.He must respect the opinions of his Colleagues.If he docs not agree with them, he must state his own position directly to his Colleagues without criticizing them or demeaning them in front of their clients.18.He must avoid disputes with his Colleagues.In the case of disagreement between Colleagues, whether in a matter relating to their practice together as partners, or in the carrying out of a juridical act required by a client, the Notaries concerned must endeavour to settle their differences amicably, and must never take action before the Courts without first referring the dispute to the President of the Hoard of Notaries.19.A Notary must never abuse thc good faith of his Colleagues, nor betray their trust in him, nor be unfair in his dealings with them.When two Notaries arc involved in the same transaction, but representing opposing interests, each must try to accommodate the other so that the clients' interests will not suffer.A Notary must not negotiate directly with the client of another Notary without his Colleague's permission.20.A Notary must co-operate with his Colleagues, so us not lo compete unfairly with them.He must when requested by a Colleague return the files and documents belonging to the Client of his Colleague 6870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n\" 18 21.En plus d'observer le règlement du tarif notarial, le notaire doit s'abstenir de critiquer les comptes d'honoraires «le ses confrères.Si après vérification d'un compte, il le juge exorbitant, il doit conseiller au client de le soumettre au secretarial de la Chambre «les Notaires pour obtenir une opinion ou, le cas échéant, une conciliation ou un arbitrage.Le notaire doit éviter dc fixer d'avance, par téléphone ou autrement, le coût de ses honoraires, alors qu'il ne connaît pas tous les éléments nécessaires lui permettant d'établir ses honoraires.37429-0 Chambre «les notaires du Québec Sun proposition dûment appuyée; il est unanimement résolu que ce «pli suit soit et est adopté comme règlement «le la Chambre des Notaires: I.l.a section IX comprenant les articles 105 et.100 «les règlements de la Chambre sont abrogés et remplacés par ce qui suit: Section IX Comptabilité en fidéicommis 105.Le notaire doit tenir une comptabilité régulière des fonds, valeurs et autres biens qui lui sont confiés en fidéicommis.105a.Le système de comptabilité en fidéicommis doit être en partie double, avec livre de caisse et grand livre; il doil aussi comprendre les livrets de reçus réglementaires, les états des dépôts et retraits bancaires, les chèques, registres et autres pièces justificatives ou de contrôle conformes aux règles et principes comptables généralement reconnus.105b.Le Conseil peut enjoindre tout notaire d'apporter à son système de comptabilité tout changement qu'il juge à propos, s'il y a lieu, pour le rendre conforme aux exigences dc la présente section.105e Tous les fonds, valeurs et autres biens ainsi confiés au notaire doivent être consignés et comptabilisés, incluant les deniers, les effets négociables payables au notaire ou au notaire en fidéicommis, ou endossés à son ordre ou à son ordre en fidéicommis, ou au porteur, dc même «pie tous les effets et valeurs au porteur ou enregistrés au nom «lu notaire ou au nom du notaire en fidéicommis.105«/.Le notaire doit, accuser reception des fonds, valeurs et autres biens qui lui sont ainsi confiés en fidéicommis en remettant au déposant un reçu officiel rédigé en la forme prescrite par la Chambre et indiquant la date du dépôt, le nom et l'adresse du déposant, la description de l'objet déposé, sa destination, le nom du notaire ou de l'étude notariale dépositaire, avec mention qu'il s'agit de fonds, valeurs ou autres biens reçus en fidéicommis et, comme tels, soumis aux dispositions «le la Loi du Notariat et des règlements dc la Chambre Ces repas doivent être reliés ou brochés en livrets et numérotés consécutivement en duplicata; le notaire doit conserver le duplicata de tout reçu qu'il émet ainsi.105c.Une copie du règlement 105V/, dans la forme prescrite par le Conseil, doit être affichée à un endroit bien en vue dans l'étude du notaire.105/.Le notaire doit déposer les fontls qu'il reçoit ainsi dans un ou des comptes de dépôts en fidéicommis, ouverts dans une ou des banques à charte, banques d'épargne ou caisses populaires.21.Not only must a Notary respect scrupulously the Notarial Tariff, but he must refrain from criticizing fees charged by other Notaries, even if he considers such fees to be excessive' counselling the complainants lo seek from the Hoard of Notaries such redress to which they may be entitled.The Notary must avoid fixing in advance hv telephone or otherwise, the amount of the fees for a deed at a time when lie docs not know tin-full extent of the services which will be required.37429-o Hoard of Notaries of the Province of Quebec Ox a motion duly seconded, il is unanimously resolved that the following be and is adopted as a by-law of the Hoard of Notaries: I.Division IX comprising sections 105 and lilt) of the by-laws are rescinded and replaced by Ihe following: Section IX Trust accounting 105.Every Notary must keep adequate accounting records of the sums of money, securities and other property entrusted to him.105a.The accounting records must he- a double-entry system with a cash book and ledger, and must include a record of the receipts issued in accordance with the by-laws of the Hoard, a record of bank deposits and withdrawals, a record of cheques issued and other records and vouchers in conformity with recognized accounting principles.105b.The Council may require a Notary lo make such changes in his accounting system as are needed in the opinion of the Council to make such system conform with the requirements of this Section.105c.All sums of money, securities and oilier property entrusted to the Notary must be recorded in his accounting system whether they he in the form of cash, negotiable instruments payable to the Notary, or to the Notary in trust, or endorsed to his order or endorsed lo his order in trust, or to bearer, as well as all securities payable to bearer or registered in the name of the Notary or in the name of the Notary in trust.105rf.The Notary must acknowledge receipt of thc sums of money, securities and other property entrusted to him by issuing to the depositor an official receipt on the form prescribed by Ihe Hoard indicating the date of the deposit, the name and address of the depositor, the description of the deposit, its purpose, the name of the Notary or of the Notarial Firm receiving the deposit and mentioning that the sums of money, securities or other property so received are subject lo Ihe provisions of the Notarial Act and by by-law of the Hoard.These receipts must be bound or stapled m books and numbered consecutively in duplicate, the Notary being bound to retain the duplicate of all receipts so issued by him.105c.A copy of by-law 105V/ in the form prescribed by the council must be posted in a pince m the Notary's office where it may be easily seen.105/.The Notary must deposit the sums he thus receives in a trust, account, or trust accounts, in a Chartered Hank, a Saving Hand or a Credit Union. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6871 Kl.'i;/.Dans les trente jours de l'ouverture de tout compte de depots en fidéicommis, le notaire doit transmettre à l'institution dépositaire du coniple en fidéicommis et au secrétaire de la Chambre, sous son serment d'office et sur les formules prescrites et fournies par la Chambre, une déclaration du fidéicommis ou trust.III.\"//.Le notaire ne peut déposer ou laisser ses fonds personnels dans son compte dc dépôts en fidéicommis.Quand il a droit de prélever ses honoraires sur des deniers qui lui ont été confiés en fidéicommis, il doit effectuer ce prélèvement el en opérer le retrait dès cpie l'opération qui a lionne lieu au dépôt est terminée.|05i.l.a comptabilité en fidéicommis doit être lemie à jour régulièrement; le notaire doit concilier, nu dernier jour de chaque mois, ses livres dc eais-e el grand livre et ses états des dépôts et retraits bancaires.Il doil aussi dresser la liste des comptes non fermés en indiquant à l'égard de chacun le nom ou le numéro cl le solde.Illôj.l.e notaire doil tenir à la disposition de chacun de ses déposants un compte constant démuni nuit l'état actuel des recettes et déboursés de toute nature effectués pour chaque compte, ainsi que les pièces justificatives s'y rapportant.Ces livres et pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix années.HI5/.\\ l.e notaire doit nommer un comptable agréé vérificateur dc sa comptabilité en fidéicommis; il doit aviser le secrétaire de la Chambre, sans délai, des noms, prénoms et adresse du vérificateur ainsi nommé dc même que de son remplaçant le cas échéant.tin cas de défaut du notaire de se conformer à celte obligation, le Conseil peut, d'office, nommer un comptable agréé dc son choix et le charger de procéder aux frais du notaire, à la vérification de sa comptabilité en fidéicommis.l.e vérificateur ne peut être parent ou allié du notaire, en ligne directe, ou au degré de frère, oncle ou sou neveu.105/.l.e vérificateur doit faire la revue générale des procédés comptables utilisés par le notaire au cours dc l'année précédente, examiner et vérifier les recel les et déboursés ayant affecté le livre de caisse, le grand livre, les états des dépôts et retraits ainsi que les preuves à l'appui: Il devra également vérifier la conciliation îles comptes en fidéicommis des instilulioiis dépositaires avec les livres du notaire ainsi que l'inventaire des fonds, valeurs et autres biens confiés au notaire par les déposants au 31 décembre précédent.l.e rapport du vérificateur du notaire doit être rédigé dans les termes dc l'annexe à la présente section.Mârn.l,c notaire doit, chaque année, avant le 30 avril: 1.l'aire procéder à la vérification dc sa comptabilité en fidéicommis, pour l'année se terminant le 31 décembre précédent.2, Transmettre au secrétaire de la Chambre, sur les formules prescrites et fournies par la Chambre: o) Une autorisation donnant le droit au Conseil, a ses officiers ou à toute autre personne que le ( ouscil pourra désigner, de requérir et d'obtenir du notaire ou de ses préposés, de son vérificateur, des institutions dépositaires de ses fonds en fidéicommis, des déposants ou de toute autre personne, tous les renseignements et explications juge, nécessaires ou utiles et d'avoir accès, en toùj temps, aux livres, comptes et pièces justificatives du notaire, relativement à sa comptabilité en fidéicommis.\\t)5g.Within thirty days after opening a trust account, the Notary must file with the institution concerned and with the Secretary of the Hoard, a Declaration of Trust under his oath of office on the form furnished by the Hoard.1056.The Notary must not deposit his personal funds in a trust account.When he has the right to deduct his fees from the funds entrusted to him, he must made this deduction and withdrawal as soon as the transaction in quest ion is completed.105i.The trust accounts must always be kept up to date.On the last day of each month the Notary must balance his cash book and ledger with his bank deposits and withdrawals.He must also prepare a list of the ledger accounts which have not been closed, with reference to the name, the number and the amount.105,?'.The Notary must keep available for each person who has deposited funds with him an account showing the current status of the receipts and disbursements as well as supporting vouchers.These accounts and vouchers must be retained by the Notary for at least ten years.105/.'.Every Notary must name a Chartered Accountant to audit his trust funds, and must submit forthwith to the Secretary of the Hoard the full name and address of such auditor or his replacement.If a Notary is in default lo meet this obligation the Council may on its own appoint a Chartered Accountant of its choice and instruct him to proceed at such Notary's expense to audit such Notary's trust accounts.Thc auditor must not be related or allied to the Notary in a direct line or within the degree of brother, uncle or nephew.105/.The auditor must make a general review of the Notary's accounting procedures for the preceding year, examine and verify the receipts and disbursements according lo the Cash Hook, the Ledger, the bank statements of deposits and withdrawals and supporting vouchers and records.He must also check the bank reconciliations with the Notary's trust accounts, trial balances and list of securities and other property entrusted to the Notary to establish their position as of the preceding 31st December.The Auditor's Report must conform with the wording of the Form wich follows this section.105wi.Every Notary must each year before the30th April: 1.Have the audit completed of his trust accounts for the year which entlcd on the preceding 31st December.2.Submit to the Secretary of the Hoard on the forms prescribed and furnished by the Hoard: (a) An authorization in favour of the Council, of its Officers and of any other person whom the Council may designate, to obtain from the Notary or from his staff, from his auditor, from his bankers, and from the persons who have made deposits with him or from any other person, all information and explanations deemed necessary or useful and to have access at any time to the books, accounts and records concerning his trust funds. GS72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1070, 102' année, n\" 1,S b) une déclaration, sous son serment d'office, attestant que tous les fonds, valeurs et autres biens qui lui ont été confiés en fidéicommis au cours de l'année précédente, ont été déposés, comptabilisés et utilisés conformément à la Loi du Notariat et aux règlements de la Chambre.Cette déclaration doit indiquer le total des recettes et déboursés effectués au cours de chaque mois, la conciliation de tous ses comptes en fidéicommis au 31 décembre précèdent, la liste (numéro et montant) des chèques en circulation et des comptes non fermés, également au 31 décembre précédent.Une seule déclaration est suffisante pour tous les notaires qui opèrent en commun un ou des comptes en fidéicommis.pourvu que cette déclaration indiqué le nom de tous les notaires qui l'opèrent et qu'elle soit signée par chacun d'eux.Le rapport du vérificateur doil être annexé à celle déclaration ou y être relié par un renvoi.105m.Le notaire qui n'a reçu aucun dépôt en fidéicommis doit transmettre au secrétaire dc la Chambre, aussi avant le 30 avril, une déclaration assermentée certifiant qu'au cours de l'année précédente qu'il n'a reçu en fidéicommis aucun fonds, valeur ou autre bien.105.Le secrétaire doit aviser dc son défaut tout notaire qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la tenue de la comptabilité en fidéicommis; cet avis doit être écrit, indiquer le défaut et être transmis uu notaire sous pli recommandé.Les frais de cet avis sont de cinq dollars (85) plus les frais de port et de recommandation: ils sont à la charge du notaire en défaut.Preuve de l'envoi dc l'avis peut être faite par le serment du secrétaire ou de ses préposés.105/».Le notaire qui, dans les trente jours de l'envoi de l'avis, n'a pas remédié au défaut, est passible d'une amende dc cinquante dollars (S50), recouvrable suivant les dispositions de la Loi du Notarial.ÎOS^.Toute contravention aux règlements de la présente section est, en outre, passible des peines disciplinaires déterminées par la Loi du Notariat.105r.La comptabilité en fidéicommis du notaire, ainsi que les états et pièces justificatives s'y rapportant sont sujets, en tout temps, à l'inspection dc la Chambre ou de ses préposés, 106.Sous réserve des dispositions des articles 105 à 105r inclusivement ci-dessus, la comptabilité en fidéicommis du notaire, ainsi que les états et pièces justificatives s'y rapportant, sont assujettis au secret professionnel.II.Lesdits règlements sont de plus modifiés en y ajoutant ce qui suit: « 125a.Une demande d'indemnisation faite en vertu des dispositions dc la présente Section peut être rejetée sur le seul motif que le requérant n'a pas exigé du notaire le reçu prévu à l'article 105silions île la troisième partie de la Loi des compagnies, en date du 15 juin 1970, et ayant son siège social en In ville de Tracy, a établi son bureau au no 2635, dc la rue Laplumc.À compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étiiiil son siège social.Daté à Tracy, le 1er jour de septembre, 1970.37-11 -l-o Le président, Gilles Farouche.404-70 Institut Yvonne Gallico inc.La compagnie « Institut Yvonne Gallico inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2435, rue Lucerne, ville Mont-Royal, du numéro 2400, rue Fullon, Montréal.Le secrétaire, Andre Hamel.374lti-o 4112-67 In ter-Canada Construction liée La compagnie « Inter-Canada Construction liée .donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 6260, 43e Avenue, Montréal au.numéro 11501, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord.Le secrétaire, Mme Hélène Charuonneau.37417-0 14942-62 Landrcvillc Transport inc.Lu compagnie « Landrcvillc Transport inc.», ilunne avis qu'elle a chungé son siège social du numéro 372, rue St-Joseph, Lanoraic-d'Autray au numéro 759, rang St-Isidore, St-Ignaee-de- Loyola.La secrétaire, Lucie Valois.37418-0 14729-61 Mylbec Corporation Avis est «lonné «pic la compagnie « Mylbec Corporation », constituée en corporation par lettres patentes en date du 27 février 1970, et ayant son siège social à Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourdh'ui au numéro 50, Place Créma/.ic, suite 1008, l'a transporté au numéro 415 est, boulevard St-Joseph.Donné à Montréal, ce 14e jour dc novembre 1970.(Sceau) IjC secrétaire, André Paquin.37410-O 972-70 l'ont Viau Employment Services Ltd.Avis est donné que la compagnie « Pont Viau Employment Services Ltd.» constitute par lettres patentes datées du 2 octobre 1970, et ayant son siège social à Laval, P.Q., a établi son bureau principal au 999, boul.Saint-Martin.A compter de la date du présent avis, ledit Bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., ce 14e jour d'octobre 1970.Club des loisirs-danse Le Marquis inc.Notice is hereby given that \"Club des loisirs-danse\" Le Marquis inc.\", incorporated by letters paient under the provisions of the third part of the Companies Act, on the 15th day of June 1970, and having its head office in the town of Tracy, has established its office at 2635 Laplumc Street.From and after the date of this notice, Ihe said office will be considered by the corporation as being the head office of the corporation.Dated at Tracy, this first day of September, 1970.Gilles Larouciie, President.37414-0 464-70 Institut Yvonne Gallico inc.Notice is given that \"Institut Yvonne Gallico inc.\", has changed its head office from number 2435 Lucerne Street, town of Mont-Royal, to number 2400 Fullon Street, Montreal.Andre Hamel, Secretary.37416 4112-67 Inter-Canada Construction ltéc Notice is given that \"Inter-Canada Construction liée\", has changed its head office from number 6260, 43rd Avenue, Montreal, to 11501 Lacordaire Boulevard, Montreal-North.Mrs.Hélène Chaiibonneau, Secretary.37417 14942-62 Landrcvillc Transport inc.Notice is given by the company \"Landrcvillc Transport inc.\", that it has changed its head office from 372 St.Joseph Street, Lanoraie-d'Autray to number 759 St.Isidore range, St-Ignacc-de-Loyola.Lucie Valois, Secretary.37418 14729-61 Mylbec Corporation _ Notice is hereby given that \"Mylbec Corporation\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated February 27, 1970, and having its head office in Montreal, has moved its head office from 50 Place Créma-zie, suite 1008, Montreal, lo 415 St-Joseph Boulevard East, Montreal.Given at Montreal, this 14th day of November, 1970.(Seal) André Paquin, Secretary.37419-0 972-70 Pont Viau Employment Services Ltd.Notice is hereby given \"Pont Viau Employment Services Ltd.\" incorporated by letters patent dated October 2, 1970 and having its head office in Laval, P.Q., has established its head office at 999 St.Martin Boulevard.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, P.Q., this 14th day of October, 1970.F.A.Cheftechi, President.37420-o 4319-70 Le président, F.A.Cheftechi.3'42(l-o 4319-70 0884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,8 Produits «le Beauté Maric-Laurc inc.Avis est donné que la compagnie « Produits de llcaulé Maric-I.aurc inc.», constituée en corporation par Ici 1res patentes en date du 17 aoûl 107(1, et ayant son siège social à Ville d'Anjou, a établi son bureau au 0351, boul.Joseph Renaud.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Ville d'Anjou, le 15 octobre 1970.Le président.Urne Lemaitre.3742 l-o 3677-70 Produits dc Beauté Marie-Laurc inc.Notice is given that \"Produits de Beauté Maric-Lburc inc.\", incorporated by letters paient dated the 17th day of August, 1070, and having its head office at Ville d'Anjou, has established its office at 0351 Joseph Renaud Boulevard.From and after the date of this notice, I lie said office is considered by the company as being its head office.(¦iven at Ville d'Anjou, October 15.1970.Rene Lemaitre.President.37421 3677-70 Universal Factory Outlet Co.Ltd.La compagnie « Universal Factory Outlet Co.Ltd.!\" donne avis qu'elle a transporté son siège social dc 100 est.rue St-Viatcur, bureau 105, Montréal, à 4153, rue Amiens, Montréal-Nord.Le secrétaire, William Coopeh.37422 3069-07 Universal Factory Outlet Co.Ltd.Notice is given that \"Universal Factory Outlet Co.Ltd.\" has transferred its head ollicc from 160, St.Viateur Street Fast, Suite 105, Montreal lo 4153 Amiens Street, Montreal North.William Cooper, Sccrclanj.37422-0 3069-67 /.ah a va Enterprises Ltd.Avis est donne que la compagnie « Zahava Enterprises Ltd.> a transféré son siège social du 175, rue Deguire.Saint-Laurent, au 4400 ouest, rue Sainte-Catherine, Westmount.l.e secrétaire-trésorier, John Wii.ks.37423 3419-70 Zahava Enterprises Ltd.Notice is given that \"Zahava Enterprises Ltd.\" transferred its head office from 175 Deguire Street, Saint-Laurent, to 4460 St.Catherine Street West, Westmount.John Wii.ks.Secretary- Treasurer.37423-o 3419-70 World Wide Special Attractions Ltd.Attractions spéciales mondiales ltéc Avis est par les présentes donné que la compagnie « World Wide Special Attractions Ltd.\u2014 Attractions spéciales mondiales liée », constituée en vertu de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 21 février 1907 et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau au 5800, avenue Monklaud.bureau 5, Montréal 201, Québec.Montréal, le 12 novembre 1970.(Seau) Le président, Hauiiy II.Cohen.37438 475-07 The Big \"O\" Plastics (Québec) Limited I.cs Plastiques Grands « 0 » (Québec) limitée Avis est donné que la compagnie « The Big \"O\" Plastics (Québec) Limited \u2014 Les Plastiques Grands « O» (Québec) limitée» a transféré son siège social de Salaberry-de-Valleyfield, dans le district dc Bcauharnois, à Coteau du Lac, dans les districts de Montréal et Bcauharnois.Le secrétaire-trésorier, F.Grant Kime.37439 1410-70 World Wide Special Attractions Ltd.Attractions spéciales mondiales ltéc Notice is hereby given that \"World Wide Special Attractions Ltd.\u2014 Attractions Spéciales Mondiales liée\", incorporated under the Coin-panics Act of Québec by letters patent dated February 21, 1967, and having its head ollicc in Montreal, has established its office at 5800 Monkland Avenue, suite 5, Montreal 261.Québec.Montreal, November 12, 1970.(Seal) Harry II.Cohen, President.37438-0 47,\">-ii7 The Big \"O\" Plastics (Québec) Limited Les Plastiques Grands «0» (Québec) limitée Notice is given that \"Thc Big \"0\" Plastics (Québec) Limited \u2014 Les Plastiques Grands « (\u2022 (Québec) limitée\" has transferred its head ollicc from Salaberry-de-Vallcyfield, in the district of Bcauharnois, to Coteau du Lac, in the districts of Montreal and Bcauharnois.F.Grant Ki.me, Secretary-Treas urer.37439-0 1410-70 Martin Draperies Inc.Avis est donné «pie la compagnie « Martin Draperies Inc.» a transféré son siège social du 4449, rue Wellington, Verdun, au 475 ouest, Port-Royal, Montréal 357.Martin Draperies Inc.Notice is given that \"Martin Draperies Inc.' transferred its head office from 4449 Wellington Street, Verdun to 475 Port Royal West, Montreal 357.Steven Hyman, Secret ary-Treas urer.37448-o 3654r04 Le secrétaire-trésorier, Steven Hvman.37448 3654-64 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Novembre 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6885 Ateliers 52 Inc.Avis esl, par les présentés, donné (pie lu compagnie « Ateliers 52 Inc.», constituée en corporation in vertu de la première partie de la Loi des compagnies (Québec), par lettres patentes émises le26 juillet 1962, et avant son siège social à Montréal.;i établi son bureau au numéro 6, Place D.Ù-clmstel, Montréal, 153.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 3e jour de septembre 1971).La secrétaire) Pi burette L.Beauvais.37156-0 13170-62 Prêts Champlain liée Champlain Loans Ltd.Avis est donné que la compagnie « Prêts Champlain liée \u2014 Champlain Loans Ltd.» constituée en corporation en vertu de la première pari i'- dc la Loi des compagnies, en date du Ci niai 1070.et ayant son siège social dans la ville de Québec, a établi son bureau au numéro 7lUi.de lu rue St-Jenn.À compter de la dale du présent avis, ledit liurenll est considéré par la compagnie comme étnill son siège social.Donné à Québec, ce 20e jour de mai 1970.Nicole Morissette.37457-0 I9S2-70 Etienne Goumoyer inc.Avis est, par les présentes donné que la compagnie « Etienne Cournoycr inc.» constituée en corporation en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies par lettres patentes émises le :àl mai 1970, et ayant son siège social à Ya-nuiska-Est, a établi son bureau au 137, rue ('cul raie.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant sou siège social.Donné à Yaniaska, ce 10e jour de novembre 11170.Le president, M.EtlEXNE CoURNOYER.37458-0 2390-70 Les Entreprises Jean Doyon liée Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Jean Doyon ltéc », constituée en corporation en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies en date du 12 juin 1970 et ayant son siège social dans la ville de Sainte-Foy, a établi son bureau au numéro 825, dc la rue Paradis.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étnill son siège social.Donné à Sainte-Foy, ce 15e jour de juin 1970.Le secrétaire, Jos.H.Doyox.37459-0 2594-70 Lavoic Datsun inc.La compagnie « La voie Datsun inc.», donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 259, boulevard d'Anjou, ChAteauguay, au numéro 555, boulevard St-.Iean-Baptiste (Rte 4), Ste-Marline, comté de Chftteauguay.Le secrétaire, Claudette V.La voie.37461-0 2625-70 Ateliers 52 Inc.Notice is hereby given that \"Ateliers 52 Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act (Québec) by letters liaient dated July 26, 1962, and having its head ollicc in Montreal has established ils ollicc at number 6, Place Duchastel, Montréal 153.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 3rd day of September, 1970.Pierrette L.Beauvais, Secretary.37456-0 13170-02 Prêts Champlain liée Champlain Loans Ltd.Notice is given thai \"Prêts Champlain liée \u2014 Champlain Loans Ltd.\" incorporated under Part I of the Companies Act, on May 6, 1970, and having its head office in the city of Québec, has established its office at 700 St.John Street.From and after the dale of this notice, the said office is considered by the company us being its head office.Given in Québec, this 20th day of May, 1970.Nicole Moiussette.37457 1982-70 Idit'iine Cournoycr inc.Notice is hereby given that \"Etienne Cournoycr inc.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent daled May 30, 1970, and having its head office in Vainaska-East, has established its office at number, 137 Centrale Street.From and after Ihe date of this notice, the said office will he considered by the company as being its head office Given at Yamaska, this lOlh day of November, 1970.M.Etienne Cournoyeh, President.37458-0 2390-70 Les Entreprises Jean Doyon ltéc Notice is given that \"Les Entreprises Jean Doyon ltéc * incorporated under Part I of the Companies Act on June 12, 1970, i(nd having its head office in the city of St.Foy, has established its office at 825 Paradis Street.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office Given in St.Foy, this 15th day of June, 1970.Jos.II.Doyon, Secrctari/.37459 2594-70 Lavoic Datsun inc.Notice is hereby given by the company \"Lavoic Datsun inc.\", that it has changed its head office from 259 d'Anjou boulevard, Chûtcatiguay, to 555 St.John thc Baptiste Boulevard (Route 4), Ste-Martinc, county of Chateauguay.Claudette V.La voie, Secrctari/.37461 2625-70 6S8G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, «° 48 La Fondation des amis dc Stc-Annc Thc Foundation of thc Friends of Sic.Anne Avis est donné que la corporation « La Fondation des amis de Stc-Annc \u2014Thc Foundation of the Friends of Sic.Anne » constituée par lettres patentes datées du 30 septembre 1070, et ayant son siège social dans Montréal, P.Q., a établi son bureau principal à Suite 700, The Royal Hank Building, Place Ville Marie.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son bureau principal.Donné à Montréal.P.Q., ce 5e jour d'octobre 1970.(Sceau) Le président, David C.Gavsib.37460-o 3145-70 La Fondation des amis dc Ste-Annc The Foundation of the Friends of Ste.Anne Notice is hereby given that \"La Fondation dos amis de Ste-Annc \u2014 The Foundation of I in-Friends of Ste.Anne\" incorporated by letters patent dated September 30, 1970, and having ils head office in Montreal, P.Q., has established ils head office at Suite 700, The Royal Bank Build, ing, Place Ville Marie.From and after the date of thc present nol ice.the said office is considered by the corporation as l>eing its head office.(liven at Montreal, P.Q., this 5th dav i>f October, 1970.(Seal) David ('.Gavsib, President.37460-o 3145-70 M.C.I.Management Ltd.Avis est donné que la compagnie « M.C.I.Management Ltd.», incorporée en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies le 4 septembre 1969 et ayant son siège social à Montréal, l'a transporté dc 1010, rue Ste-Cathe-rinc Ouest, à 1255, rue Université.IsC secrétaire, Stanley Clamen.37462-o 4220-69 M.CI.Management Ltd.Notice is hereby given that \"M.C.I.Management Ltd.\", incorporated under Part I of the Companies Act on September 4, 1969 and having its head office in Montreal, has transferred il from 1010 St.Catherine Street West, to 1255 University Street.Stanley Clamen, Secretary.37462-0 4220-00 Maison Nadcau limitée La compagnie « Maison Nadcau limitée », constituée en corporation, en vertu des lettres patentes en date du 14 janvier 1947 et ayant son siège social dans la cité de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 7120, rue des Erables, l'a transporté au numéro 1259, rue Boni, suite 200.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné ù Montréal, ce 2le jour de septembre 1970.Le secrétaire, (i aston N a de au.37463-0 1538-47 Gilles Martin, I liane Martin inc.Avis est donné que la compagnie « (iillcs Martin, Fhane Martin inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 11 mai 1970, et ayant son siège social à Montréal, a établi son bureau principal au 3100, Tour de la Bourse, Place Victoria.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, le 11 mai 1970.(Sceau) Le président, Gilles Martin.37464-0 2028-70 Molson Scpl-Iles Itée Avis est donné (pic la compagnie < Molson Sept-Ilcs ltéc », constituée en corporation en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 26 novembre 196S, a transporté son siège social dc 250, rue Arnaud.Scpt-Iles, i\\ 115, Mgr Blanche (Sceau) Le secrétaire, Robert de Fouoerollbs.37467-o 5606-68 Maison Nadcau limitée Notice is given that \"Maison Nadcau limitée\", incorporated by letters patent dated January 14, 1947 and having its head office in the city of Montreal until to-day ut 7120 des Erables Street, has established its head office at I25!l Berri Street, room 200.From and after the date of the présent notice, the said office is considered by the company ns being its head office Given at Montreal, this 21st day of September.1970.Gaston Nadeau, Secretary.37463-0 1638-47 Gilles Martin, Élianc Martin inc.Notice is hereby given that \"Gilles Martin.Klinne Martin inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated May 11, 1970, und having its head office in the city of Montreal, has established its ollicc ut 3100 Stock Exchange Building, Victoria Square.From and after thc date of this notice, the said office shall be considered by thc company as being thc head office of the company.Dated at Montreal, May 11, 1970.(Seal) Gilles Martin, President.37464-0 2028-70 Molson Sept-Ilcs ltéc Notice is hereby given that \"Molson Sept-Iles Itée\", incorporated under Part I of II\"' Companies Act by letters patent dated November 26, 1968, has moved its head office from 250 Arnaud Street, Sept-Ilcs, to 115 Mgr Blanche; (Seal) Robert de Fougeroli.es, Secretary.37467-0 5600-08 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1070, Vol.102, No.h8 6887 Metallisation du Nord inc.Avis esl donné que la compagnie « Metallisation du Nord inc.», constituée en corporation dale du Ge jour de mai 1970, et ayant son siege social dans la ville de Cliibougamau, a établi son bureau au numéro 878, Quartier Industriel.A compter dc la dale du présent avis ledil bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Cliibougamau, ce 4e jour de novembre 1970.Philippe Lessard.37465-0 1942-70 Metallisation du Nord inc.Notice is given that \"Metallisation du Nord inc.\", incorporated on the Gib day of May, 1970 and having its head office in the town of Cliibougamau, has established its ollicc at 878 Quartier Industriel.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given in Cliibougamau, this 4lh day of November, 1970.Philippe Lessard.37405 1942-70 .Molina 1er orncmcnlul Itée Molina Ornementa] Iron Ltd.A\\ is est par la présente donné que la compagnie < .Molina fer ornemental liée -\u2014 Molina Ornc-nicnliil Iron Ltd.», incorporée suivant la première part» de la Loi des compagnies, par lettres patentes émisés en date du 23 juillet 19G2, a déménagé son siège social du 8140, rue Lafrc-aaie.à Si-Léonard, au 8275, rue Lafrcnaie, à Sl-I.éonard, district de Montréal.Montréal, le 9 novembre 1970.(Sceau) Le secretaire, Thérèse Laruffa.374110-.1312-62 Mortgage Consultants Inc.Avis est donné que la compagnies « Mortgage Consultants Inc.», constituée en corporation par lettres palenles en date du 19e jour de juillet 1961, cl ayant son siège à 1010 ouest, rue StC-Cnlliirinc dans la ville dc Montréal, district de Montréal, a transporté son bureau au numéro 1255; rue University, dans la ville dc .Montréal, ilislricl de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau esl considéré par la compagnie comme étnill son siège social.Daté à Montréal, ce 22e jour dc juin, 1970.Le secrétaire, Ethel Prehooan.37468-0 13361-61 Itcalisations Mont-Chatcl inc.Avis est donné (pu- la compagnie « Réalisations Moiit-Chatel inc.», constituée en corporation en vertu de In première partie de la loi des compagnies en date du 24 octobre 1909 et ayant son siège social dans In ville dc Sainte-Foy, a établi son bureau au numéro 825, de la rue Paradis.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie connue elnnl son siège social.Donné à Sainte-Foy, ce 15c jour de juin 1970.Le secrétaire, Jos.IL Doyon.37469-0 5100-09 Les Soeurs de l'Assomption dc la Sainte-Vierge, Province dc Notre-Dame dc Lourdes l.a corporation * Les Soeurs de l'Assomption île la Sainte-Vierge, Province de Notre-Dame de .Lourdes » donne avis qu'elle a changé son siège social de Nicolct au numéro 1G35 rue F'radct, tbummondville Sud.La secrétaire, Germaine Faquin, s.a.s.v.37470-o 10650-61 .Molina 1er ornementa] liée Molina Ornemental Iron Ltd.Notice is hereby given that \"Molina fer ornemental liée \u2014 Molina Ornemental Iron Ltd.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent issued on July 23, 1902, has moved its head office from 8140 Lafrcnaie Street, in St.Léonard, to 8275 Lafrcnaie Street, in St.Léonard, district of Montreal.Montreal, November 9, 1970.(Seal) Thérèse Laruffa, Secretary, 37406-o 1312-62 Morlgagc Consultants Inc.Notice is hereby given that \"Mortgage Consultants Inc.\", incorporated by letters patent on the 19lh day of July, 1961, and having its head office at 1010 St.Catherine Street West in the city of Montreal, district of Montreal, has moved its office to 1255 University Street in the city of Montreal, district of Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 22nd day of June, 1970.Ethel Prehooan, Secretary.3740S-o 13361-61 Réalisations Mont-Chatcl inc.Notice is given that ''Réalisations Mont-Chalel inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act on October 24, 1909 and having its head office in the city of St.Foy, has established its office at 825 Paradis Street.From and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given in St.Foy.this 15th day of June, 1970.Jos.II.Doyon, Secretary.374G9 5160-69 Les Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge, Province dc Notre-Dumc «le Lourdes Notice is given that \"Les Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge, Province de Notre-Dame de Lourdes\" has changed its head office from Nicolct to number 1635 Fradet Street, Drumniondville South.Germaine Paquin, s.a.s.v., Secretary, 37470 10650-61 68S8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n' 18 Sorccom inc.Avis est donne que la compagnie « Sorccom inc.», constituée en corporation sous la première partie dc la Loi des compagnies, en date du 10 juillet 1909 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, province de Québec, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro civique 3540, rue Joliette, Montréal, Québec, l'a transporté au numéro civique 110 ouest, C'réma/.ie Montréal, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 5e jour d'octobre 1970.(Sceau) 3747 l-o Roger Dubuc.3440-69 Sorccom inc.Notice is given that \"Sorccom inc.\" incorporated under l'art I of the Companies Act, on July 10, 1969, and having its head office in the city cif Montreal, Province of Québec, where it had its office situated until today to Civic number 3540 Joliette Street, Montreal, Quebec, has transferred it to civic number 110 Créma/.ic West, Mont-real, Québec.Prom and after the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given in Montreal, this 5th day of October 1970.(Seal) Roger Ledit.37471 34411-119 qu Incos Limited La compagnie « Incos Limited » donne avis .,j'elle a transporté son siège social de 1485-A rue Latour, St-Hubert à 300, Canal Bank, section #16, Ville Sl-Picrrc.Le .secrétaire, Théo Saxgesser.37499 2719-65 Incos Limited Notice is given that \"Incos Limited\" has transferred its head office from 14S5-A Labour Street, St.Hubert to 300 Canal Bank, Section #10, Ville St.Pierre.Théo Saxgesser, Secretary.37499-0 2719-65 Le Meuble Villageois inc.La compagnie « Le Meuble Villageois inc.» donne avis qu'elle a change son siège social du numéro 6635, rue Papineau, Brassard à Saint-Benoit Labre, comté dc Beaucc.Le .secrétaire, Clermont Poulin.37500-O 1584-69 Le Meuble Villageois inc.Notice is given that \"Le Meuble Villageois inc.\" has changed its head office from 6635 Papineau Street, Brassard to Saint-Benoit Labre, county of Beaucc.Clermont Poulin.Secrctari/.37500 1584-69 La Scie Cliapais inc.La compagnie « La Scie Cliapais inc.\" donne avis qu'elle a changé son siège social de Thetford-Mines à Chapais, comté d'Abitibi, CP.188.Le .secrétaire, Jean-Louis Mahbu.37501-O 1394-69 La Scie Chapais inc.Notice is given that \"La Scie Chapais inc.\" lias moved its head office from Thctford Mine- In Cliapais, county of Abitibi, CP.188.Jean-Louis Maheu, Secrctari/.37501 1394-09 Ventes pour taxes Sales for Taxes Ville de St-Bruno dc Montarvillc Avis public est par les présentes donné par le soussigné, trésorier et assistant-greffier de la ville de St-Bruno de Montarvillc, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère public, à l'Hôtel de Ville de la ville de St-Bruno de Montarvillc, 1585, rue Montarvillc, le LUNDI, le VINGT ET UNIÈME jour dc DÉCEMBRE, 1970, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires et répartition, avec intérêt plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payées avant la vente.L& Commission municipale dc Québec, par décision en date du 22 octobre 1970, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550, tel qu'amendé par 24, George V, chapitre 33, section 3.Town of St-Bruno dc Montarvillc Public notice is hereby given by the undersigned.Treasurer and Assistant Town-Clerk of the Town of St-Bruno de Montarvillc, thai I lie hereinafter described immoveables will be sold by public auction, at the Town Hall of the Town of St-Bruno de Montarvillc, 1585 Montarvillc Street, on MONDAY, TWENTY-FIRST day of DECEMBER, 1970, at TEN o'clock in the forenoon to satisfy the payment of the municipal and school taxes plus the costs which shall subsequently be incurred unless thc said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission by a decision dated October 22, 1970, has authorized and abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables under the authority of I lie article 550 of Cities and Towns Act, as amended by 24, George V, chapter 33, section 3. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 12, 1970, Vol.102, No.IS ossn Noms des Propriétaires Name of Proprietors Cadustre Subdivision M.-Mi.ot-nnd Mine-Mrs.Henrik Freund.M.-Mr.cl-and Mmc-Mrs.Henrik Freund.Koreiii / Hiinr.Ml-llruno lienltics Inc.('.-\u2022'.¦ partie du lot originaire cent trente et un du radnstro officiel t centièmes (10a 17) pieds, sur le boulevard Clairevue; borné à l'est sur li rue De Carillon; borné au nord par lo lot 402-81-î-j, ipiKirtennnt :\"l Jcan-Ouy Lessard; d'une superficie ccenl soixante-deux pieds carrés et sept centièmes I 002 07) pieds carrés.Jules.Mangin.Aveu bâtisse portant numéro civique 1784 rue Venliiu.91.01.120.1*131.87.129.31.This part of original lot number one hundred thirty-one (i'131) of thc cadastre of the parish of St-Bruno, bounded in front one hundred five feet and thirty-seven hundredth (105.37) feet, on Clairevue Boulevard; bounded on the east on De Carillon street; lwunded on the north by lot number 402-81-2-1, belonging to Mr.Jean-Guy Lessard; having a total area of one thousand six hundred and sixty-two square feet and seven hundredth (1.G02.07) square feet.I 131.1 243-21.With building bearing civic number 1784 Verdun Street.Benoît i ouitois.Main iec Massicot 10.Kirluird M.Blala.i.& /.! ne.Claud A.Akkaoui.Avec bâtisse portant numéro civique 1975 Place Nightingale.Claud A.Akkaoui.Avec bâtisse portant numéro civique 1975 l'Inro Nightingale.Daniel v.Ailler.Mmc-Mrs, Anna Schubert.Minc-.Mra.Alzbcla Kmmer.172.172.221.231.314.1-1.1-10.83.13.8-2-2.With building bearing civic number 1975 Nightingale Place.I 314.1 9.With building bearing civic number 1975 Nightingale Place.492.492.492.149.150.151.I.e.immeubles susdits sont tous aux plan cl livre de renvoi officiels de lu paroisse de St-Itruno maintenant Ville de St-Bruno de Montarvillc et situés dans ladite ville.Je bureau d'enregis-Ireini ut de In ville est situe au 201 Place Charles l.eMoyuc.Longucuil.Ladite vcnle sera en outre fuite avec tous les droits de subrogation, toutes les servitudes active- ou passives apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donne en lu Ville de St-Bruno de Montarvillc, ce Oc jour du mois dc novembre, 1970.IjC trésorier el l'assistant-greffier, 3732-1-47-2-0 J.P.R.Boissy.The above immoveables arc all on the plan and book of reference of the parish of St-Bruno now Town of St-Bruno dc Montarvillc and situated in the said town, the registration office of the said town is situated at 201 Place Charles LcMoyne, Longucuil.The said sale will be made with all subrogation rights, and all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at the Town of St-Bruno de Montarvillc, this 9lh day of November, 1970.1.P.R.Boissy, 37324-47-2-0 Treasurer antl Assistait! Town-Clerk.Cité de Stc-Tliércsc Avis esl par le présent donné par le soussigné, Gliarlcs-Ëdouard Dcsjardins, greffier de lu cité de Sainte-Thérèse, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus ù l'enchère en la salle municipale dc l'Hôtel de Ville, dc la cité dc Sic-Thérèse, 38 ouest, rue Blainvillc, LUNDI, le DIX HUITIÈME jour de JANVIER 1971, à l'I'.l \\ heures de l'après-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec i lU'-réts et les frais subséquemment encourus a moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.Toutefois, seront exclus de la vente des immeubles sur lesquels les taxes municipales devenues exigibles, le ou avant le 31 décembre 1969 auront été payées avant le moini ut de la vente.La Commission municipale dc Québec, par une décision en date du 14 octobre 1970, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux il immeubles à être vendus par la Cité pour non-Paieincnt de taxes, d'ici le 28 février 1971, à condition que ladite enumeration abrégée ne s applique qu'aux numéros cadastraux d'immeubles (pu sont consécutifs et qui appartiennent au ineiue propriétaire, le tout conformément aux dépositions de l'article 550 de la Loi des cités et ville (S.R.Q.1964, chapitre 193).City of Stc-Thérèsc Notice is hereby given by Ihe undersigned, Charles-Edouard Desjardins, City-Clerk of the city of Ste.Thérèse, that the immovable properties hereunder described will be sold by public auction in the Municipal Hall of the city of Ste.Thérèse, 38 Blainvillc Street West, on MONDAY, the EIGHTEENTH day of JANUARY, 1971, at TWO o'clock in the afternoon to satisfy, the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the cost which have been or may incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before sale.However the immovables on which the taxes exigible on or before December 31, 1969, shall be paid before the time of the sale, shall be excluded from the side.The Quebec Municipal Commission by a decision dated October 14, 1970, has authorized an abridged enumeration of the cadastral lots numbers to be sold by the aforesaid City for taxes before February 28, 1971, on condition that the said abridged enumeration applied itself only to thc cadastral lot numbers of immovables which are consecutive and are belonging to the same owner, according to the provisions of article 550 of the Towns and Cities Act (S.R.Q.1964, chapter 193). 6890 GAZETTE OFFIC TELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' aimée, n° 18 Noms Nomes Adresse Address Cadastre Lebcnu, Paid- Emile.Lebeau, Paul-Emile.Mercure.André.Degongrc, Jean.Gagnon, Alfred.Charron, Leopold.Charron.Leopold.Les Habitations Dencn.437, Blninville Est, Ste-Thérèse.437, Blninville Kst, Ste-Thérèse.40, Côte St-Louis, Ste-Thércse.104, Desjardins Est, Ste-Thérèse- 4, rue Tlogue, Ste-Thérèse.51(i, Boni.Du Coteau, Ste-Thérèse.510, Boni.Du Coteau, St-Thérêse.1017, \\'al Martin.Chomedey, Laval.Filiatrault, Nolan.Matte, Marcel.Coller, Mme Fernand.50 ouest, Blainvillc.Ste-Thérèse.7781, St-Denis, Montréal.33, rue St-Louis, Ste-Thérèse.234-4,-5 (P).234-12 (P).541-141,547-1 (P).510-108, 01-02, 01-03 (P) 01-04.207-25,-20 (P).554-393 (P).564-302 (P).550-118, 54S-10G (P).548-107.54S-108, 518-109, 540-134.550-110.550-117, 548-100.518-101.518-102.648-103.550-105, 551-511.550-101, 551-510.550-103, 551-509.550-102, 551-508.550-101, 551-507.550-100, 551-500.550-159, 551-505.551-501, 550-158.551-503.551-370, 550-114.550-115.550-148,-140.518-153.-154.550-150,-151.518-155, -150.550-152, 548-157.550-153, 648-168.550-151, 548-159.550-155.518-100.551-480, 550-150.551-181, 550-157.551-482,-483.115-250 (V).244 (V).P27 (V).Désignation: Un emplacement situé rue St-Louis, en la cité dc Sainte-Thérèse, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro vingt-sept fPtic 27) aux plan et livre dc renvoi officiel du village dë Ste-Thérèse de Blainvillc, et contenu duns les bornes suivantes: F.n avant vers le nord-est, par la rue St-Louis, en arrière vers le sud-ouest, par la propriété dc M.11er-ménégilde Thibault, représentant Dame Veuve Guillaume Thibault; d'un côté vers le nord-ouest par la propriété de Dame A.Debien, représentant M.J.-A.Perron; et de l'autre côté vers le sud-est, parla propriété de M.J.O'Reilly, représentant Dame Veuve Léger Jérôme.Desionalion: A lot situated in front of St-Louis Street in the city of Sainte-Thérèse known and designated :ia being a part of the original lot mimljcr twenty-peveh (Pt 27) of thc Official cadastre of thc parish of Ste.Thérèse de Blainvillc and included in thc following boundaries: in front to thc northeast, by St-I.outs Street, in thc back line to thc southwest, by thc property of Mr.Hcrniénégildc Thibault, representing Mrs\".Guillaume Thibault, widow; on one side t>> the northwest, by thc property of Mrs.A.Debien, representing Mr.J.-A.Perron and on the ottier side to die southeast by the property of Mr.J.O'ltcilly, repr.siting Mrs.Léger Jérôme, widow.Jacques Denault Inc.Chomedey, Laval \u2014\t551-551 (P).\" ¦ \u2022 ¦ >\t551-553.\t551-552.\t551-555, 653-620.» ____\t551-550, 553-521.V .\t551-557, 553-522. signifie l'offre dc vente, la vente, l'expédition pour fin dc vente, le transport, l'achat, cl l'entreposage ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant Irait à l'écoulement du produit visé; les expressions «lait», « marchand de lait » el « fabrique 1 ont.la même signification que celle Indiquée dans la loi des produits laiticrsctde leurs succédanés; l'expression « Fédération signifie la Fédération des producteurs dc lait du Quélx-c.cl l'expression « Régie » signifie la Régie des Marchés Agricoles du Québec.III.Désignation: Le plan conjoint est désigné sous le nom do « Plan conjoint des producteurs dc lait du Québec ».IV.Produit risé: Le produit visé par ce plan esl tout le lait provenant du troupeau d'un producteur intéressé, dans le sens donné à celle expression à la section V.V.Conditions à remplir pour être un producteur intéressé: lx producteur intéressé au sens du présent plan est toute personne admise par la Régie ou par un organisme chargé d'appliquer un plan conjoint comme fournisseur de lait à une usine de pasteurisation ou à un marché dc lait nature dans In province de Québec.VI.Extension juridique: À compter de sa publication dans la Gazelle officielle dc Québec, le plan est exécutoire.Tous les producteurs intéressés et, postérieurement au vote, tous les producteurs qui, au cours de la durée dc l'application du plan, continuent à remplir ou répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur intéressé, sont assujettis au plan.VIL Realisation du plan: L'exécution el l'administration du plan sont fiées à la Fédération des producteurs de lait du Québec.VIII.Agent de négociation cl de vente: La Fédération est l'agent de négociation et l'agent dc vente pour l'exécution du plan.IX.Devoirs, obligations el engagements du producteur: increase the productivity and to apply the sola-tions deemed advantageous for all producers; 4.To take and participate in any initiative aiming at increasing the consumption of the contemplated product; 5.Rutionali/.c the transportation of the con-tcmplated product; 6.To take any measures aiming at lutving Hie producer to share the marketing costs, including thc disposal of milk and milk products surpluses; 7.To co-operate with any organization on the national and provincial levels for the marketing of this product.II.Definitions: In thc present joint plan, the word \"marketing'1 means the offer to sell, thc sale, the transportation, the purchase and the warehousing lo;, titer with the advertising and the financing of the operations related to the disposal of thc contemplated product; thc words \"milk\", \"milk dealer\" and \"factory\" have the same meaning as Ihe one indicated in the Dairy Products and Dairy Products Substitutes Act; the word \"Federation\" means the Fédération des producteurs de lait du Québec: the word \"Hoard\" means the Québec Agricultural Marketing Hoard.III.Designation: The joint plan shall be designated as: \"Queliec Milk Producers' Joint Plan\".IV.Contemplated product: The contemplated product is all Ihe milk issuing from thc herd of an interested producer, in the sense given to this expression in section V hereafter.V.Conditions required lo be an interested producer: Any person who is permitted by the Hoard or by an organization entrusted with the carrying out of a joint plan to act as a milk supplier lo a pasteurization plant or to fluid milk market in the Province of Québec, is an interested producer.VI.Legal extension: From thc date of its publication in the Québte Official Gazette, thc joint plan is executory.It binds all interested producers and, subsequent lo the votation, all producers who, during the course of its carrying out, continue to fulfil or me< I the conditions, required to be qualified as interested producers.VII.Carrying out of the plan: La Fédération des producteurs de lait du Québtt is entrusted with the carrying out and administration of thc joint plan.VIII.Negotiating and sales agent: The negotiating and sales agent, designated fer the carrying out of the plan shall be the federation.IX.Duties, obligations and commitment \"! producers: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.48 0903 I,, producteur doit: 1.Si' conformer aux décisions et règlements adoptés pur lu Fédération dans l'exercice des pouvoirs dont clic est investie en vertu de la Loi (les marchés agricoles du Quélicc; 2.Honorer toute convention et tout contrat fait- par la Fédération ou son délégué dans l'exercice de ses pouvoirs et attributions; 3.Si la Federation adopte un règlement à cette lin.se procurer un quota de production et de vente auprès de la Fédération et le respecter; I.Se conformer aux normes dc qualité établies par l'autorité compétente et la Fédération et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit vise; \"i.l'ayer les frais d'administration cl dc mise en oeuvre du plan selon le montant cl les modalités que la Fédération établira; li.l'ayer sa quote-part de toute somme due à un voiliirier et à toute autre personne dont l'intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités éta-blies par elle, cl autoriser tout marchand dc laiton Unite |iersonne qui touche le produit globnl d'une venir en commun, à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou ù toute personne désignée par elle; T.Contribuer, selon les modalités établies par la Fédération, au coût de l'écoulement des surplus de luit et dc produits laitiers ut t ri! niables aux producteurs vises; 8.Utiliser les contenants pour fins dc livraison ilu produit visé répondant aux normes établies par la federation en conformité avec les lois en vigueur et les marquer conformément aux normes prescrites par la Fédération; '.i.Fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l'exécution du plan.Y \u2014 Devoirs de la Fédération en tant qu'office de 1*1*1 licteurs, agent de négociation et agent dc renie: l.e» devoirs de la Fédération sont: 1.Accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi des marchés agricoles du Québec, impose à un office de producteurs; '.'.Orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre l'offre et la demande du produit visé; 3.\\ iser à assurer la mise en marché d'un produit de qualité conforme aux règlements et aux nonnes d'inspection décrétés par l'autorité compel ci île.et I.Maintenir une comptabilité selon les standard- minima que peut exiger la Régie XI.Pouvoirs el attributions de la Fédération en laut qu'office de producteurs, agent de négociation et agent dc rente: l.a Fédération peut: _ 1.Coopérer avec des organismes similaires au Cnnudu pour la mise en marché hors de la province du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent dc toute loi d'une autre juridiction prévoyant une telle coopération: Exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d'une délégation dc l'un quelconque des pouvoirs remis par la Régie; 3.Contingenter lu production et la vente du produit visé, fixer le temps et le lieu de sa mise The producer must: 1.Conform with all decision and regulations adopted by the Federation, using the powers granted to the latter under the Québec Agricultural Marketing Act; 2.Honour any agreement and any contract made by the Federation or its delegate, in the exercise of it.s powers and attributions; 3.If the Federation has adopted a regulation to that effect, obtain from the same a production and marketing quota and abide by it; 4.Conform with the standards of quality established by the competent authority and the Federation and submit to any inspection intentcd to verify the quality of the contemplated product; 5.Defray the administration and implementation costs of the plan according to the amount and conditions that the Federation shall establish; 6.Fay its share of any sum due to a carrier and to any other person whose intervention is necessary and services retained by the Federation for the marketing of thc contemplated product, according to the methods established by it, and authorize any milk dealer or any person receiving the lump sum resulting from the point marketing of the product to deduct this share and remit it to the Federation or lo any person designated by it; 7.Share the cost of the disposal of milk and milk products surpluses due lo thc producers bound by the plan; 8.Use, for delivery purpose, containers which meet the standards established by the Federation, in accordance with laws in force, and mark them according to the labelling standards prescribed by the Federation: 9.Provide the Federation with any information deemed useful to the carrying out of the plan.X.Duties of the Federation in its capacity as a producers' board, and as a negotiating and selling agent: The duties of the Federation arc: 1.to perform all duties and obligations imposed on a producers' board under the Québec Agricultural Marketing Act; 2.to direct production in accordance with the requirements of the markets, and try to maintain a judicious balance between supply and demand of thc contemplated product; 3.to assure the marketing of a quality product in conformity with regulations and inspection standards decreed by the competent authority, and 4.to keep its books in conformity with the Hoard's requirements.XI.Powers and attributions of the Federation in its capacity as a producers' board and as a negotiating and selling agent: The Federation may: 1.Co-operate with similar bodies in Canada for the marketing outside the Province of Québec of the contemplated product and, for this purpose, exercise the powers and perform the duties resulting from any law from another jurisdiction providing for such a co-operation; 2.Exercise any power and perform duties resulting from the delegation of any one of the Hoard's powers; 3.Establish quota for production and sale, fix the time and place of marketing, prohibit mar- G904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,8 en marché, prohiber la mise en marché hors du temps ou du lieu fixé ou en violation des quotas établis ou d'une norme imposée; 4.Retenir les services dc voituriers et autres personnes dont l'intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé, et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode dc perception; 5.Arrêter la participation financière de chaque producteur à l'administration du plan ainsi que le mode de perception dc cette participation; G.Affecter une partie dc la contribution versée par les producteurs pour l'administration du plan à des fins dc publicité du produit visé; 7.Pour réaliser l'un quelconque des aspects de la mise en marché du produit visé, et entre autres pour fin de publicité du luit et des produits laitiers, décréter avec l'approbation dc la Régie et de l'assemblée générale des producteurs visés, une contribution spéciale de tous les producteurs ou d'un groupe déterminé dc producteurs; 8.Déterminer les montants et les modalités dc paiements d'une contribution des producteurs au coût de l'écoulement «le leurs surplus dc lait et de produits laitiers; 9.Statuer sur les conditions de production et dc conservation du produit visé, sur sa qualité, sur le récipient qui le contient, sur les inscriptions ou indications requises sur le récipient; 10.Garantir les quantités et qualités requises par les marchands dc lait et obliger le producteur à satisfaire à ces exigences; 11.Ordonner, organiser et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs dont le produit est vendu pendant une période fixée et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique dc même quantité et d'égale qualité mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin: a) ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des frais d'exécution dc surveillance et dc vérification encourus au sujet de ces ventes; 6) prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun, le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement au marchand dc lait, le cas échéant, de l'excédent du prix fixé sur le prix de vente; c) obliger le marchand «le lait à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser à la Fédération ou à un agent dc vente l'excédant du prix dc vente sur le !>rix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, la fédération ou agent de vente rembourse l'excédent au marchand dc lait; d) obliger le marchand dc lait à verser le prix du produit visé à la Fédération ou à un agent de vente pour que la Fédération ou agent de vente fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur.12.Signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement; kcling outside thc fixed time or place or in violation of thc established quota or of a prescribed rule; 4.Retain thc services of carriers, processors, warehousemen and of any other person whose intervention is necessary for thc marketing of I Ik-product, to ensure payment of services rendered, and determine thc share that each producer must pay, as well us thc mode of collection; 5.Determine the financial contribution of each producer for thc administration of the joint plan, as well as thc means of collecting this contribution ; 0.Utilize a part of the producers' contribution to the administration of thc joint plan for advertising purposes of the contemplated product: 7.For the carrying out of uny as|K-et of the marketing of thc contemplated product ami, among other things, for the advertising of milk and milk products, order with the approval of the Hoard and of the general meeting of flic interested producers, a special contribution for all producers or for a specified group of producers; S.Determine the amounts and the methods of payment of thc contribution of the producers to the cost of the disposal of their milk ami milk products surpluses; 9.Determine the conditions of product ion and preservation of the contemplated produel, the quality, shape and composition thereof, the receptacle or package containing the same.I lie inscriptions or indications required on I lie product, receptacle or package; 1(1.Guarantee the quantities and the quality required by the buyers, and compel producers lo meet these requirements; 11.Order, organize and supervise the joint marketing of the contemplated product, in order that the producers whose products are sold during a fixed period and on a designated market shall each receive from the proceeds of sale the same price for an identical product of the same quantity and equal quality but the sale price of which may vary for reasons unconnected with the real value of the product, and to this end: («) To order that there shall be deducted from the proceeds of sale the whole or part of the cost of carrying out, supervision and audit incurred with respect to such sales; (b) To prescribe the conditions under which joint sales shall be made, the payment of thc sale price, thc sharing of the net proceed- of sales among producers, the provisional fixing prior to sale und the final fixing after side of the price to be paid to the producer for his product, the payment of the price so fixed ami the repayment to the milk dealer, should the case occur, of the excess of the fixed price aver the sole price; r) To compel the milk dealer to pay t\" tlie producer the price fixed for his product and, should the occasion arise, to pay to the Federation or to a selling agent the excess of the sale price over the fixed price; if the fixed price exceeds the sale price, the Federation or UK selling agent shall repay the excess to the milk denier; (J) To compel the milk dealer to pay the price of the contemplated product to the Federation or to a selling agent, so that the sharjaî of the net proceeds of sale be made according to regulations in force.12.Sign any contract and, thereby, bind each producer subjected to the joint plan, and determine thc duration and conditions for its renewal; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.18 6905 i:i.Établir un Comité de bonne entente jwur étudier el solutionner les griefs des producteurs relativement à l'exécution du plan, en déterminer les règlements et la portée de ses décisions; I i, Obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile ù l'exécution du plan; I\").Paire toute enquête requise pur les buts et objectifs du plan; 10.Négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu dc la Loi des marchés agricoles, toute condition de mise en marché, et spéciale-mcnl : «i le prix de vente du produit visé, y compris de- prix différents selon diverses dusses de luit établies selon son utilisation; b) le» conditions et modalités de paiement du prix du produit visé; ri la rationalisation des circuits, les conditions, modalités et prix du transport, ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé; i/i les conditions dc livraison; c) la qualité, la quantité du produit visé: /) In surveillance par un représentant de la fédération, du poids, de la qualité et dc la teneur en grus ou autre constituant du produit visé: g) suivant la classification et l'utilisation du produit visé, les conditions dc surveillance du paiement fait par le marchand de lait et de toute remise faite par toute personne qui louche le produil global d'une vente en commun; h) le» inodes de retenue par le marchand dc lait ou toute personne qui touche le produit global d'une vente en commun, de la contribution nécessaire au financement du plan ou d'une contribution spéciale et sa remise à la Fédération ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d'un service rendu par un intermédiaire et sa remise à la Fédération ou son délégué; i ) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations; j) tant à l'occasion dc la signature d'une convention qu'au cours de son exécution, une procédure de règlement et d'arbitrage des griefs et des différends.XII.Administration du plan conjoin!: I.Le plan conjoint est administré par la Fédération dont le Conseil d'Administration est présentement composé des personnes suivantes: Lucien St-Pierre, cultivateur HH.I, Rimouski Jules-Henri Robichaud, cultivateur St.lcan-1'ort-Joli Comté dc l'Islcl \u2022Manel Mailloux, cultivateur R.R.l.Granby Comté de Shefiord Holland Desjardins, cultivateur Stç-Félicité, R.R.1 fondé de Matane André Rioux, cultivateur Mont-Joli, R.R.2 Comté de Rimouski Lucien Williams, cultivateur Saint-Céznirc Comté de Rouvillc 13.Establish a Good Will Committee to study and find solution to the producers' grievances with respect to the carrying out of the joint plan, determine the regulations of thc Committee and the full implication of its decisions; 14.Obtain from the producers all information judged useful to carry out the joint plan effectively; 15.Make all inquiries of such a nature as lo attain the ends set down in the joint plan; 16.Xegociatc with any person bound to do so by thc Québec Agricultural Marketing Act all the marketing conditions, and more specifically: (a) The selling price of thc contemplated product, including various prices for different classes of milk according lo its utilization; {b) Thc conditions and the methods of payment of the price of the contemplated product; (c) The rationalization of the routes, thc conditions, means and cost of transportation or of any service related to the marketing of the contemplated product; (rf) Thc delivery conditions; (c) The quality, the quantity of thc contemplated product; (J) The supervision of thc weight, the quality, thc percentage of huttcrfut or any other constituent of thc contemplated product; (g) According to the classification and utilization of thc contemplated product, the supervision conditions of the payment made by thc milk dealer and of any remittance made by any person receiving the lump sum from the joint marketing of the product; (//) The methods of withholding by the purchaser or by any person receiving the lump sum from the joint marketing of the product of thc necessary contribution to finance the joint plan and its remittance to the Federation as well as of any sum required for the payment of services rendered by a middleman, and its remittance to the Federation or its delegate; (i) The duration of agreements as well as the conditions for their renewal and those permitting the reopening of negotiations; (j) Thc settlement and arbitration procedures relating to grievances and disputes both at the time of signing, and during thc course of an agreement.XII.Administration of Ihe joint plan: 1.The joint plan shall be administered by the Federation, whose Hoard of Directors is presently made up of the following persons: Eugène Jancllc, cultivateur St-Cyrille dc Wendovcr Comté de Drummond Roger Rousseau, cultivateur Nicolct-Sud Comté dc Nicolct Paul-Emile Gratton, cultivateur Saint-Benoît Comté des Dcux-Montagncs Henri Girard, cultivateur 655 Rivière Sud St-Eustachc Comté des Deux-Montagnes René Miehon, cultivateur Saint-Thomas d'Aquin Comté de St-Hyacinthe Grégoire Bessette, cultivateur Mont-Grégoire Comté d'Ibervillc G906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° i8 Réjcan Grégoire, cultivateur Napicrvillc (.'ointe de Xupicrvillc Robert (iélinas, cultivateur Mocamic Comté d'Abilihi-Oucst Paul A.Tardif, cultivateur Suint-Nicolas Comté dc Lévis Germain Rodrigue, cultivateur Beauceville-Est Comté dc la Beaucc Léo Lacliancc, cultivateur 411 St-Gcrmain, Rimouski Comté de Rimouski Jean-Maurice Coulombe, cultivateur Shipshaw, R.R.1 Comté de Dubuc 2.Les administrateurs dc la Fédération doivent être des producteurs intéressés au sens dc la section V des présentes; 3.Le mode dc remplacement et d'élection ou de nomination des administrateurs subséquents est celui prévu par les règlements de la Fédération; 4.l,a Fédération doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au plan conjoint pour rendre compte dc ses activités en tant qu'olliec, soumettre les comptes de l'exercice à l'approbation dc l'assemblée et procéder à la nomination d'un vérificateur; 5.Sauf les cas où la Loi des marchés agricoles assujettit l'application d'un règlement à sa publication dans lu Gaulle officielle tlu Québec, la publication des règlements ayant rapport aux modalités d'exécution tlu plan et à l'exercice des pouvoirs de la Fédération, est faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal « La Terre dc Chez-Nous ».Tout règlement ainsi publié entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.6.Si la Fédération ne représente pas dans l'opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le plan, la Régie peut décréter, après audition des parties intéressées, qu'un office dc producteurs est chargé, à une date fixée, de l'exécution et dc l'administration du plan.Cet Office de producteurs est composé d'administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.L'Office de producteurs, et ses administrateurs, auront les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à la Fédération en vertu des présentes; et les biens et obligations dc la Fédération qu'elle a obtenus à titre d'administrateur du plan conjoint, seront transférés à cet Office de producteurs dc la façon prescrite par la Régie Si la Fédération peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu'elle représente dc nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie pourra, en suivant la même procédure que ci-dessus, lui confier l'administration et l'exécution du plan, L'Office des producteurs sera alors aboli.XIII.Mule dc financement: L'administration et la mise en oeuvre du plan sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le plan selon le mode déterminé par la Fédération.Guy Meilleur, cultivateur St-.lovitc, R.R.2 Comté de Terrebonne Dollard Cournoycr, cultivateur Ste-Victoire Comté dc Richelieu Serge Gamcau, cultivateur Bluck-Lakc Comté dc Mégantic .los-Jules Bélanger, cultivateur 3c rang Est, Trois-Pistolcs Comté dc Rimouski Paul-André Tremblay, cultivateur Ste-Barbc Comté d'Huntingdon Elphègc Allurd, cultivateur Victoriavillc.R.R.2 Comté d'Arthabaska 2.The administrators of thc Federation nuis! lie interested producers with the meaning of Section V of these presents; 3.The method of nominating and of electing or replacing subsequent administrators shall he that provided for in the Federations' regulations; 4.The Federation must convene and hod I.nt leust once a year, a general meeting of all tin-producers subjected to thc joint plan lo rcndcr.as a producers' Board, an account of its activities, .submit financial reports for approval and proceed lo Ihe nomination of an auditor; 5.Should thc application of a Board's regulation be subjected lo its publication in the Québec Official Gazette, the regulations related to the modalities of the carrying out of thc joint plan and the exercise of the Federation's powers shall he published in French and English in \"La Terre de Chez-Nous\".Every regulation thus published in \"La Terre dc Chez-Nous\" shall come into force on the fifteenth day after publication or on such later dulc ns may be fixed therein.G.If the Federation does not, in the opinion of the Board, represent the majority of the producers bound by the joint plan, the Board can decree, after hearing the parties concerned, that a Producers' Board shall be entrusted, at a given date, with the carrying out and administra I ion of the joint plnn.This Producers' Board shall be made up of administrators elected by the interested producers at a -pecial general meeting convened to this end by the Board.The Producers' Board and its administra tors shall have the rights, duties and attribution! granted to the Federation under these presents, and the assets and obligations of the Federation which it obtained as administrator of the joint plan will be transferred to this Producers' lb mil m the manner prescribed by the Board.If, afterwards, thc Federation can prove lo the satisfaction of the Board that it again represents the absolute majority of the interested producers the said Board may, by following the procedure outlined above, entrust the Federation with the administration and carrying out of the joint plan.Thc Producers' Board shall then be abolished.XIII.Financing: The administration and carrying oui ol (hf joint plan shall be financed through a contribution which must be paid by all producers bound by the joint plan, according to the method selected by the Federation. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.18 6907 l.i' montant de cette contribution est déterminé par 1« Fédération au moyen d'un règlement qui doit élrc approuvé par l'assemblée générale des producteurs et par la Régie avant d'entrer en vigueur.Jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par un loi règlement, la contribution est dc trois cents cl demi (0.035) le cent (100) livres de lait livré ,\"i un marchand dc lait.Les contributions versées à la Fédération en verlu de la Loi des marchés agricoles du Québec, doivent servir à défrayer les dépenses de l'admi-nislration et de la mise en oeuvre du plan.XIV.Comité consxdtatif: 1.Afin dc permettre aux divers secteurs intéressés de faire des recommandations aux organismes chargés de la commercialisation du produit visé, un comité consultatif sera formé dans les deux mois dc la mise en vigueur du plan.2.ur toute l'émission; cependant, si plus d un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortis- Cité de Verdun County of Verdun Public notice is hereby given that scaled tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Mr.J.N.Lcfcbvrc, clerk, City Hall, 4555 Verdun Avenue, Verdun, county of Verdun, P.Q., until 12:00 noon, on Monday, December 14, 1970, for the purchase of an issue of S-l.070,000 of bonds for the city of Verdun, county of Verdun, dated January 1, 1971 and redeemable serially from January 1, 1972 to January 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 8) nor more than 9J 2%.payable semi-annually on January 1st and .Inly 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rale is used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, C912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 88 novembre 1970, 102' année.n° 1,S Scmcnts annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1971.Tableau d'amortissement \u2014 SI,,070,000 \u2014 20 ans Aimée Capital 1er janvier 1972.S 22,000 1er janvier 1973.24,000 1er janvier 1974.27,000 1er janvier 1975.29,000 1er janvier 1976.32,000 1er janvier 1977.35,000 1er janvier 197S.37,000 1er janvier 1979.42,000 1er janvier 1980.46,000 1er janvier 19S1.50,000 1er janvier 1982.55,000 1er janvier 19S3.60,000 1er janvier 19S4 .66,000 1er janvier 19S5.71,000 1er janvier 19S6.78,000 1er janvier 19S7.86,000 1er janvier 19SS.95,000 1er janvier 1989.103,000 1er janvier 1990.113,000 1er janvier 1991.2,999,000 Kn plus, les modalités suivantes seulement seront, considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2e Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quin/.ième année.3° Obligations échéant, en série 1 à 10 ans avec le solde à terme 20 ans.4e Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe20 ans ne devront lias être pour un montant inférieur à 8111,000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparissanl dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 2011 dc la partie renouvelable ci-après indiquée Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un setd des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.I.'adjudication sera faite conformément à la loi.1,'échéancc du 1er janvier 1991 au montant de S2.999.000 comprend un solde de 82,875,000 renouvelable pour une période additionnelle dc 20 ans, et échéant commesuil: Année Capital 1er janvier 1992.8130,000 1er janvier 1993.149,000 1er janvier 1994.163,000 1er janvier 1995.178,000 1er janvier 1996.195,000 1er janvier 1997.213,000 1er janvier 1998 .234,000 1er janvier 1999.256,000 1er janvier 2000 .281,000 1er janvier 2001.307,000 1er janvier 2002.49,000 1er janvier 2003 .54,000 1er janvier 2004 .59,000 1er janvier 2005 .64,000 1er janvier 2006.70,000 1er janvier 2007.77,000 1er janvier 2008.85,000 as shown on the tables of redemption in this notice For adjudication only, interest shall be i-al-culalcd as from January 1, 1971.Table of redemption \u2014 $A,070,000 \u2014 20 yean Year Capital January 1,1972.S 22,001) January 1, 1973 .24,00(1 January 1, 1974 .27,00(1 January 1.1975.29,00(1 January 1, 1970.32,000 January 1, 1977 .35,01111 January 1, 1978 .37,0(1(1 January 1, 1979.42,000 January 1, 1980.40,00(1 January 1, 1981.50.01 Hi January 1, 1982.55.01 lu January 1, 1983 .60,000 January 1, 1984.60,00(1 January 1, 1985.71,000 January 1,1986 .78,000 January 1, 1987 .86,0(in January 1, 1988 .95,000 January 1, 1989.103,0011 Janaurv 1, 1990.113,0011 January 1,1991.2.999.000 Moreover, the following tenus and conditions only shall be considered: 1.One to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One to 15-year serial Iwnds with the balance carried over lo the fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year term bonds.4.One to 10-ycar serial bonds with the ha lance carried over 10-year for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter modality, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an aniounl less than 8111,000.and if greater than the latter amount, the said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the nblcs of redemption appearing in this notice, and starting with the Insl years of maturities excluding the maturity of January 1, 2011 of the renewable part hereafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity of January 1, 1991 in the ui lotnt of 82,999,000 includes a balance of $2,875,000 renewable for an additional 20-ycar period, ami maturing as follows: Year Capital January 1, 1992.8136,000 January 1, 1993.149,000 January 1, 1994.163.000 January 1, 1995.178,000 January 1, 1996.195,000 January 1, 1997 .213,001) January 1,1998 .234,000 January 1, 1999 .256,000 January 1, 2000 .281.000 January 1, 2001.307;.January 1, 2002.49,00(1 January 1, 2003 .54,000 January 1,2004.59,6011 January 1,2005.64,000 January 1,2006.70,000 January 1,2007.77 .(\"«I January 1,2008 .85,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.IS 6913 |,r janvier 2009.S 93,000 1er Janvier 2010.101,000 1er janvier 2011.111,000 l.e capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la lmni|ue dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal île ladde banque à Toronto, Ontario.Lcsililcs obligations ne seront pas raeliclables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme lixc 20 ans pour un montant supérieur à 82,999,000 et seul cet excédent sera racbelable par anticipation au pair le 1er janvier dc cbuquc année pour le montant annuel requis pour les lins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend mi ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.ladites obligations seront émises en vertu du règlement no 817 \u2014 84,070,000 \u2014 aqueduc, égouls, voirie, éclairage, services récréatifs et communautaires.Les soumissions seront ouvertes et considérées à nue séance du conseil qui sera tenue lundi, le 14 décembre 1970, à 12 heures (midi), Hôtel tic ville.1555, ave Verdun, Verdun, comté dc Verdun.l».Q.l,e conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Verdun (Comté dc Verdun), ce 18 novembre 10711.Le greffier, .1.N.Lefebvue, Hôtel de ville, 4555, ave Verdun, Verdun.(Verdun), P.Q.Téléphone: 769-2701, code 514.37475-0 January 1, 2009.S 93,000 January 1, 2010.101,000 January 1, 2011.111,000 Capital and interest are payable at all branches in the province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation save if they were issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount higher than 82.999.000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the amount required to amortize the issue in accordance with thc table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of thc issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the dale of their delivery is included or not in the price of the tender.Thc said bonds will be issued pursuant lo by-law No.817 \u2014 84,070,000 \u2014 aqueduct, sewers, roads, lighting, recreational and community services.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, December 14, 1970, at 12:00 (noon), at the City Hall, 4555 Verdun Avenue, Verdun, county of Verdun, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Verdun (Countv of Verdun), November IS, 1070.J.N.Cefedviie, Clerk.City Hull, 4555 Verdun Avenue, Verdun, (Verdun), P.Q.Telephone: 769-2701, code 514.37475 Ville dc La Prairie Comté de Napicrville-Lnprairie Avis public est par les présentes domic que de- soumissions cachetées et portant l'inscription \u2022 Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné monsieur Leopold Pélndeau, greffier.Hôtel de ville, 600, boulevard Stc-Éliza-lictli, l.a Prairie, comté dc Nnpicrvillc-Laprairie, P.Q., jusqu'il 8.30 heures du soir, mardi, le 15 décembre 1970, pour l'achat de S457.000 d'obligations de la ville de La Prairie, comté dc Nupicr-villc-l.aprairie, datées du 1er janvier 1971et remboursables en série du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8)£%, ni supérieur à 9>2%, payable senii-aimiicllcnient les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut cire le même pour toute l'émission; cepedant, si plus d'un taux est utilisé-, le montant émis à disque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $457,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er janvier 1972.810,000 1er janvier 1973.18,000 1er janvier 1974.18,000 1er janvier 1975.18,000 f* '«\u2022r janvier 1976.18,000 1er janvier 1977 .21,000 Town of Lu Prairie County of Napicrville-Liipriiiric Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Mr.Leopold Péladcau, Town Clerk, Town Hall, 600 Sainte-Elisabeth Boulevard, La Prairie, county of Napiervillc-l.aprairie, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., Tuesday, December 15, 1970, for the purchase of a bond issue of 8457,000, bonds of the town of La Prairie, county of Napierville-Laprairie, dated January 1, 1971, and redeemable serially from January 1, 1972 to January 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 814%> »or n,orc t'\"\"1 9)4%, payable semiannually on January 1st and July 1st each year.The rate of interest may be thc same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on thc table of redemption on this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from January 1, 1971.Table of redemption \u2014 $457,000 \u2014 20 years Year Capital January 1, 1972.816,000 January 1, 1973.18,000 January 1, 1974.18,000 January 1, 1975.18,000 Januury 1, 1976.18,000 January 1, 1977.21,000 0914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° .',8 1er janvier 1978.§21.000 1er janvier 1979.21,000 1er janvier 19S0.21.000 1er janvier 19S1.21,000 1er janvier 1982.24,000 1er janvier 1983.25,000 1er janvier 1984 .25,000 1er janvier 1985.25,000 1er janvier 1980.25,000 1er janvier 19S7.28,000 1er janvier 198S.28,000 1er janvier 1989.28,000 1er janvier 1990.28,000 1er janvier 1991.28,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde rci>orté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour celte dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $28,000 et si supérieur à ce dernier moulant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seid des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf datis le cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à La Prairie.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.I.csdites obligations ne seront pas rachclablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S2S.000 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément nu tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesditcs obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 325 \u2014 SS.0O0 \u2014 aqueduc, égouts; 364 \u2014 $21,000 \u2014 aqueduc, égouts; 367 (369) \u2014 8165,000 \u2014 aqueduc, égouts, 372 \u2014 S100.000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie, électricité, etc.; 375 \u2014 840,000 \u2014 aqueduc, égouts; 3S8 \u2014 $123,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, le 15 décembre 1970, à 8.30 heures du soir.Hôtel dc ville, 600 boulevard Ste-Éli/.abcth, La Prairie, comté dc Napicrville-I.aprairic, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.January 1, 1978 .821.01)11 January 1, 1979.21.0(10 January 1, 1980.21,0011 January 1, 1981.,.21,006 January 1, 1982.24,000 January 1, 1983.25,000 January 1, 1984 .25,000 January 1, 1985.25.11! io January 1, 1986.25,000 January 1, 1987 .28,000 January 1, 19SS.28,000 January 1, 19S9 .28,000 January 1, 1990.28.000 January 1, 1991.28.000 Moreover, thc following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried over to thc tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried over lo Ihe fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-ycar fixed term bonds.4.One to 10-year serial bonds with llir balance carried over to 10 years for one pari ami as 20-year fixed-term bonds for thc other part.However, in ihe case of the latter term, Ihe 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than 828,000, and if greater In Ihe hitler amount, said part must only comprise one or several complete annual amortizations, hiking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, the 1st of January 1991 maturity being excluded.However, tenders shall be sent for one of Ihe above methods of issue only, and they -hull comprise one only of the terms, save hi I he cast of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be nuulc according to law.The successful tenderer agrees lo pay for the bonds, capital and accrued interest, if any.I»y certified cheque payable ut par in La Prairie.Capital and interest arc payable at all branches in the province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation, except if they arc issued partly is 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 828.000 and the said surplus only will he redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notke.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount ol llif issue and must specify whether interest accrued on the bonds to thc date of their delivery h included or not in the price of the tende]'.Thc said lionds will be issued under the folk*-ing by-laws: 325 \u2014 $S,000 \u2014 aqueduct, sewers; 364 \u2014 $21,000 \u2014 aqueduct, sewers; 367 (309) -S165.000 \u2014 aqueduct, sewers; 372 \u2014 $100,000-aqucduet, sewers, roads, electricity, etc.: 375 \u2014 $40,000 \u2014 aqueduct, sewers; 388 \u2014 8123,000-oqiieduct, sewers.Tenders will be opened and considered at « meeting of the council to be held on Dceenibjr 15, 1970, at 8:30 o'clock p.m., at the Town Haft 600 Saintc-Élizabeth Boulevard, La Prairie, county of Xapicrvillc-Laprairie, P.Q.The council does not bind itself to accept II* highest or any of the tenders. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, J970, Vol.102, No.J,8 6915 La Prairie (Comic dc Napierville-Laprairie), ce 20 novembre 1970./.c greffier, Leopold Peladeau.Hold de ville, COO, boulevard Stc-Kliznbcth, l.a Prairie, (Napierville-Laprairie), P.Q,, Telephone: 059-1947, code 514.37502-d Cité de Scpl-Iles Comté dc Duplcssis Avis public est pur les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription < Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Georges Bélanger, greffier, Bétel de Ville, 540, rue Dequcn, Sept-Ilcs, comté île Duplcssis, P.Q., jusqu'à 2 heures de l'après-midi, lundi, le 14 décembre 1970, pour l'achat de S1S00O0 d'obligations de la cité de Sept-Ilcs, comté (le Duplcssis, datées du 1er janvier 1971 et remboursables par séries du 1er janvier 1972 un 1er janvier 1991 inclusivement, avec intérêt â mi taux non inférieur à SCj%, ni supérieur à ¦J1 _>',.payable scmi-nnnuellemcnt les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, -i plus d'un taux esl utilisé, le montant éini- a chaque taux différent doil couvrir un ou îles amortissements annuels entiers, tels que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1971.Tableau d'amortissement \u2014 SI86,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er janvier 1972.S 5,000 1er janvier 1973 .5,500 hi-janvier 1974 .0.000 1er janvier 1975.6,500 1er janvier 1976.7,500 1er janvier 1977 .8,500 1er janvier 197S.9,500 1er janvier 1979.10,500 1er janvier I9S0.12,000 1er janvier 1981.13,000 1er janvier 1982.14,500 1er janvier 1983.15,500 1er janvier 1984.17,000 1er janvier 1985.19,000 1er janvier 1986 .20.0(H) 1er janvier 1987 .2,500 1er janvier 198S.3,000 1er janvier 1989 .3,000 1er janvier 1990.3,500 1er janvier 1991.4,000 Eu plus, les modalités suivantes seulement .seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et I autre partie à terme fixe 20 ans.I oiilefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant ù terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant, inférieur à «4,000 el si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis et en commençant par les dernières années irmi'éances excluant l'échéance du 1er janvier La Prairie (County of Napierville-Laprairie), November 20, 1970.Leopold Péladeau, Clerk.Town Hull, 000 Ste-Klizabeth Boulevard, La Prairie, (Napierville-Laprairie), P.Q., Telephone : 659-1947, code 514.37502 City of Scpl-Iles Counly of Duplcssis Public notice is hereby given thai sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Georges Bélanger, Clerk, City Hall, 540 Dequcn Street, Spct-Ilcs, county of Duplcssis, P.Q., until 2:00 o'clock p.m., on Monday, December 14, 1970, for the purchase of an issue of 8180,000 of bonds for the city of Sept-Iles, county of Duplcssis, dated January I, 1971 and redeemable serially from January 1, 1972 to January 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than £}¦¦>%, nor more than 9ji%.payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown in the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from January 1, 1971.Table of rédemption \u2014 8186,000 \u2014 20 years Year Capital January 1, 1972.S 5,000 Januarv 1, 1973 .5,500 January 1, 1974.0,000 Jununrv 1, 1975.6,500 January 1, 1976.7,500 January 1, 1977.8,500 January 1, 1978 .9,500 January 1, 1979.10,500 January 1, 1980.12,000 January 1, 1981.13,000 January 1, 1982.14,500 January 1, 1983.15,500 January 1, 1984.17,(MM) January 1, 1985.19,000 January 1, 19S6.20,000 January 1, 1987 .2,500 January 1, 19SS.3,000 January 1, 1989.3,000 January 1, 1990 .3,500 January 1, 1991.4,000 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered : 1.One lo 10-ycar serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One to 15-ycar serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried over as 10-ycar bonds for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter modality, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than 84,000, and if greater than the latter amount, the said part must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of maturities appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of January 1, 1991. 0910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2S novembre 1970, 102' année, n\" 1,S Cependant, les soumissions ne devront être transmises (pic pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées, l'adjudication sera faite conformément à la loi._ L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Sept-Ilcs.Le capital el les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom esl mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas rachetablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme b'xe 20 ans pour un montant supérieur à 84,000 et seul Cet excédent sera rachctable par anticipation an pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de rémission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque .soumission devra être accompagnée (l'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment, dc leur livraison.Lcsdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 310 \u2014 830.000 \u2014 aqueduc, égouts; 311 \u2014 8150,000 \u2014 fonds de roulement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 14 décembre 1070, à 2 heures de l'après-midi.Hôtel de Ville, 540, rue Dequcn, Scpl-Iles, comté dc Duplcssis, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sept-Ilcs (Comté de Duplcssis), ce 23 novembre 1070.Le greffier, Georges Bklangek.Hôtel dc Ville, 540, rue Dequen, Sept-Ilcs (Comté de Duplcssis), P.Q.Téléphone: 902-2525, code 41S.37504-b Les Commissaires d'écoles pour la municipalité dc la ville de Rimouski Comté dc Rimouski Avis public est par les présentes donné (pie des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par lcjsoussigné André A.Ross, sécréta ire-trésorier.Ecole Secondaire Langcvin, 99 ouest, rue St-Jean-Baplistc, Rimouski, comté dc Rimouski, P.Q., jusqu'à 5 heures de l'après-midi, mercredi, le 16 décembre 1970, pour l'achat de 8145,000 d'obligations des commissaires d'écoles pour la municipalité de la ville dc Rimouski, comlé de Rimouski, datées du 1er janvier 1971 et remboursables par séries du 1er janvier 1972 au 1er janvier 19S1 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à SJ4%, ni supérieur à 9)4% payable seini-annucllcment les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1971.However, tenders shall be sent for one of i||C above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.Thc successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, bv certified cheque payable at par al Scpt-Ilesl Capital and interest arc payable at all brunches in the Province of Quebec of thc bank mentioned in the loan procedure as well as at the bead office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable hy anticipation save if they are issued partly an 20-year fixed-term bonds for an amount grenier than 84,000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on January l-t ol each year for the annual amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice Each tender must be accompanied by a certified cheque equal lo 1% of the amount of tlie issue and must specify whether interest accrued on the bonds lo the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 310 \u2014 836.000 \u2014 aqueduct, sewers; 311 \u2014 S150,000 \u2014 working capital.Tenders will be opened and considered al a meeting of the council to be held on Monday, December 14, 1970.at 2:00 o'clock p.m., al I lie City Hall, 540 Dequen Street, Scpl-Iles.coiinlr of Duplcssis, P.Q.The council does nol bind itself lo accept tlie highest or any of Ihe lenders.Scpl-Iles (Countv of Duplcssis), November 23, 1970.Georges Belaxgeh, Clerk, City Hall, 546 Dequcn Street, Sept-Iles (County of Duplcssis).P.Q.Telephone: 962-2525, code 418.375(14 Thc School Commissioners for the Municipality of the Town of Rimouski County of Rimouski Public notice is hereby given that sealed tenders bearing Ihe inscription \"Tenders for Ronds\" will be received by the undersigned André A.Ross, Secretary-Treasurer, Langcvin High School, 99 St-Jcnn-Raptistc Street West.Rimouski, county of Rimouski, P.Q., up lo 5:00 o'clock p.m., Wednesday, December Iti, 1970, for the purchase of S145.000 of bonds for the school commissioners for the municipality of the town of Rimouski, county of Rimouski, dated January 1, 1971 and redeemable serially from January 1, 1972 to January 1, 19S1 inclusively, with interest at a rate not less than 8J ¦/,'(\u2022 nor more than 9}-;%, payable semi-annually on January 1 and July 1 of each year.The rale of interest may be thc same for the whole issue; however, if more than one rate is used, llic amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this nol ice.For adjudication purposes only, interest shall be calculated as from January 1, 1971. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 88, 1970, Vol.102, No.iS 6917 Tableau d'amortissement \u2014 §11,5,000 \u2014 10 ans Table of redemption \u2014 SI1,5,000 \u2014 10 years Annie Capital Year Capital 1er janvier 1972.S 9,500 January 1, 1972.S 9,500 1er Janvier 1973.10,000 January 1, 1973.10,000 1er janvier 1974.11,000 January 1, 1974.11,000 1er janvier 1975.12,500 January 1, 1975.12,500 1er Janvier1976.13,500 January 1, 1970.13,500 1er Janvier 1977.14,500 January 1, 1977.14,500 1er janvier 1978.16,000 January 1, 1978.16,000 I.r janvier 1979.17,500 January 1, 1979.17,500 1er Janvier 1980.19,500 January 1, 1980.19,500 1er Janvier 1981.21,000 January 1, 1981.21,000 On esl.prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant te tableau ci-dessus seulement, et cpie les plfrcs qui seront faites pour des obligations à courte échéance rie seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y n lieu, par chèque visé, payable au pair à Rimouski.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladile banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas raehetables par anticipation.('Inique soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt el devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lcsdites obligations seront émises en vertu de la résolution d'emprunt datée du 28 septembre 1970 \u2014 8145,000 \u2014 dépenses en immobilisations 1969-70.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 16 décembre 1970, à 5 heures île l'après-midi, École Secondaire Langcvin, III) ouest, rue St-Jcan-I$aptiste, Rimouski, comté de liiuioiiski, P.Q.Le- commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des sou-inis-lons.Rimouski (Comté de Rimouski), ce 23 novembre 1070.Le secrdaire-lrhoricr, Aximfe A.Ross.Kcole Secondaire Langcvin, 99 ouest, rue St-Jeun-Baptiste, liimouski (Rimouski), P.Q.Téléphone: 724-4492, code 418.37523-o Attention is called lo the fact that tenders arc requested for bonds redeemable according lo Ihe above-mentioned table only, and that any offer which might be made for short-term bonds will nol be considered.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for Lite bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Rimouski.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in Ihe loan procedure as well as at Ihe head office of tlie said bank at Toronto, Ontario.Thc said bonds shall not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue, and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the lender.The said bonds will be issued pursuant to the loan resolution dated September 28, 1970 \u2014 S145.000 \u2014 expenditures of capital assets 1969-70.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Wednesday, December 16, 1970 of 5:00 p.m., Langcvin High School, 99 Sl-Jean-Baptiste Street Wesl, Rimouski, county of Rimouski, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Rimouski (County of Rimouski), dated November 23, 1970.Andre A.Ross, Sécréta ry-Treasurer.Langcvin High School, 99 St-Jean-Baptiste Street West, Rimouski (Rimouski), P.Q.Telephone: 724-4492, code 418.37523 Ville dc Roxboro Comté dc Robert Baldwin A .is public est par les présentes donné que îles soumissions cachetées et portant l'inscription ' Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné V.P.Gray, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 13, Cenlrc commercial, Roxboro, coin lé de Robert Baldwin, P.Q., jusqu'à S heures 'lu soir mercredi, le 16 décembre 1970, pour l'achat dc S146.000 d'obligations dc la ville de Roxboro, comté de Robert Baldwin, datées du 1er janvier 1970 et remboursables par séries du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991 inclusivement avec intérêt à un taux non inférieur à 8J4%, ni supérieur à 934%, payable semi-annuellcment les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute Town of Roxboro County of Robert Baldwin Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, V.P.Gray, secretary-treasurer, Town Hall, 13 Commercial Centre, Roxboro, county of Robert Baldwin, P.Q.up to 8:00 p.m., Wednesday, December 16, 1970, for the purchase of a bond issue of S146.000, bonds of the town of Roxboro, county of Robert Baldwin, dated January 1, 1971 and redeemable serially from January 1, 1972 to January 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than &/>%, nor more than 9}4%, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; G91S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n' 48 l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels (pic montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1971.Tableau d'amortissement \u2014 811,6,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er janvier 1972.S 3,000 1er janvier 1973.3,500 1er janvier 1974.3,500 1er janvier 1975.3.500 1er janvier 1970.4,000 1er janvier 1977.4,500 1er janvier 1978.5,500 1er janvier 1979 .5,500 1er janvier 1980 .0,000 1er janvier 1981.0,000 1er janvier 1982 .0,500 1er janvier 1983.7,000 1er janvier 19S4.8,000 1er janvier 1985.9,000 1er janvier 19S0.9,500 1er janvier 1987.10,500 1er janvier 1988.11,000 1er janvier 1989.12,000 1er janvier 1990.13,000 1er janvier 1991.14,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1e Obligations échéant en séries 1 à 10 insavec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en séries 1 à 15 ans avec le solde rcjiorte à la quinzième année 3° Obligations échéant en séries 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 814,500 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières aimées d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Roxboro.Le capital cl les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal dc ladite banque à Toronto, Ontario.Lcsdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un moulant supérieur à 814,500 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rale must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the tables of redemption in tins notice For adjudication only, interest will be calculated as from January, 1, 1971.Table of redemption \u2014 811,6,000 \u2014 20 atari Year Capital January 1, 1972.S 3,00(1 January 1, 1973.3,600 January 1, 1974.3,5011 January 1, 1975.3,500 January 1, 1976.4,000 January 1, 1977.4,500 January 1, 1978.5,500 January 1, 1979 .5.500 January'1, 1980 .6.000 January 1, 19S1.6,000 January 1, 1982.0,500 January 1, 1983.7.000 January 1, 1984 .8,000 January 1.1985.9.000 January 1, 1986.9.500 January 1, 1987.10.500 January 1, 1988.11.000 January 1, 1989.12,000 January I, 1990.13.000 January 1, 1991.14,500 Moreover, the following tenus and conditions only shall be considered: 1.Ronds maturing serially in 1 to 10 years with the balance brought forward to the lentil year.2.Ronds maturing serially in 1 to 15 years with the balance brought forward lo the fifteenth year.3.Ronds maturing serially in 1 lo 10 years with the balance as a 20-ycar fixed term.4.Ronds maturing serially in 1 to 10 years with the balance brought forward to 10 years in pari and the other part as a 20-year fixed term.However, where the last tenus and conditions are concerned, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than 814.500, and if greater than thc latter amount, said part must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starling with the lusl years of maturities excluding llie maturity date of January 1, 1991.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of thc exceptions stipulated herein.Adjudicalu n shall be made according lo law.The successful tenderer agrees lo pay for Ihe bonds, capital and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Roxboro.Capital and interest arc payable at all brain ! s in the province of Québec of the bank mcntii mil in the loan procedure as well as at the head cilice of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued partly as 20-yi »r fixed-term bonds for an amount greater than S14.500 and this surplus alone will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required lo amortize thc issue, in accordance with the table of maturities of thc issue appearing in this notice QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1070, Vol.102, So.48 G919 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.I.c-dilcs obligations seront émises en vertu des règh ments suivants: 210 \u2014 $90,100 \u2014 aqueduc, égouK voirie; 214 \u2014 828,500 \u2014 construction d'une bibliotiiôque municipale; 221 \u2014 89,500 \u2014 services récréatifs et communautaires; 220 \u2014 S13.SO0 - amélioration du parc; 201 \u2014 84,100 \u2014 aehiit «le machinerie.I.omissions seront ouvertes et considérées ù une séance du conseil qui serti tenue, mercredi, le 10 décembre 1070, à 8 heures du soir, Hôtel de ville.13, Centre commercial, Roxboro, comté de Robert Baldwin, P.Q.I.c conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plu* haute ni aucune des soumissions.Iloxhoro (Comté dc Robert Baldwin), ce 23 hum inbrc 1970.Le secrétaire-trésorier, V.P.Gray.Hold de ville, 13, ' entre commercial, Boxboro (Comté de Robert Baldwin.P.Q.Téléphone: 084-0555, code 511.37524-o Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on thc bonds lo the date of their delivery is included or nol in Ihe price of the lender.Thc said bonds will be issued under Ihe following by-laws: 210 \u2014 890,100 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 214 \u2014 828,500 \u2014 building of a municipal library; 221 \u2014 89,500 recreational and community services; 220 \u2014 813,800 \u2014 improvement of the park; 201 \u2014 S4.100 \u2014 purchase of machinery.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held Wednesday, December 10, 1970, at 8:00 p.m., Town Hall, 13 Commercial Centre, Roxboro, county of Robert Baldwin, P.Q.Thc council does nol bind itself to accept thc highest or any of the tenders.Roxboro (County of Robert Baldwin), November 23, 1970.V.P.Gray, Secretary-Treasurer.Town Hull, 13 Commercial Centre, Roxboro (County of Robert Baldwin), P.Q.Telephone: 084-0555, code 514.37524 Village dc Vcrchcrcs Comté de Vcrchcrcs Avis public est pur les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Philippe Collette, secrétaire-trésorier, jusqU'A 5 heures dc l'après-midi, Bureau du secrétaire-trésorier, 1, rue St-Louis, c:im po-lalc 250, Verchèrcs.Village, comte dc Verchèrcs, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir.Salle de comté, OU .Marie Victoria, Ver-clièn - Village, comté de Verchèrcs, P.Q;, mardi, le 15 décembre 1970, pour l'achat dc 862,000 d'obligations du village dc Verchèrcs, comté de Verchèrcs, datées du 1er janvier 1971 et remboursables par série du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à SJ{.%, ni supérieur à $¦}¦¦>%, payable, seini-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même |>our toute l'émission; cependant, si plus d'un laux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels «pie montré au tableau d'amortissement duns le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calcul,' A compter du 1er janvier 1971.Tall mi d'amortissement \u2014 862,000 \u2014 20 ans .Innée Capital 1er janvier 1972.81,000 1er janvier 1973.1,000 1er janvier 1074.1,500 1er janvier 1975.1,500 1er janvier 1976.1,500 1er janvier 1977 .2,000 1er janvier 1978.2,000 1er janvier 1979.2,000 1er janvier 1980.2,500 1er janvier 1081.2,500 1er janvier 1982 .3,000 1er janvier 1983.3,000 1er janvier 1984 .3,500 1er janvier 1985.3,500 1er janvier 1986.4,000 1er janvier 1987.4,500 Kr janvier 1988.5,000 Villugc of Vcrchcrcs County of Verchèrcs Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Philippe Collette, Secretary-Treasurer, until 5:00 o'clock p.m., at the ollicc of the Secretary-Treasurer, I St.Louis Street, Post Office Box 250, village of Verchèrc, county of Verchèrcs, P.Q,, and after until 8:00 o'clock p.m., at the County Hall, 011 Marie Victorin, village of Verchèrcs, county of Verchèrcs, P.Q., on Tuesday, December 15, 1970, for the purchase of an issue of 802,000 of bonds for the village of Verchèrcs, county of Verchèrcs, dated January I, 1971 and redeemable serially from January I, 1972 lo January 1, 1991 inclusively, with interest at a rate nol less than 8JHI%> nor more t ban 9) ¦'>%.payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for Ihe whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on thc table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from January 1, 1971.Table of redemption \u2014 $62,000 \u2014 20 years Year Capital January 1, 1972 .81,000 January I, 1973.1,000 Januurv 1, 1974.1,500 January 1, 1975.1,500 Januurv 1, 1976.1,500 January 1, 1977.2,000 January 1, 197S.2,000 January 1, 1979 .2,000 Januurv I, 1980.2,500 January 1, 1981.2.500 January 1, 1982.3,000 Januurv 1.1983.3,000 January 1, 1984 .3,500 January 1, 1985 .3,500 January 1, 1986.4,000 January 1, 1987 .4,500 January 1, 1988 .5,000 G920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,8 1er janvier 1989.85,500 1er janvier 1990.0,000 1er janvier 1991.0,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporte à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4e Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, |K»ur cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $6,500 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans la présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises (pie pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des des tenues sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Verchèrcs.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec dc la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lcsdites obligations ne seront pas raehclablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $6,500 et seul cet excédent sera l'achetable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission conformément au ' tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lcsdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: 158 \u2014 $62,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 15 décembre 1970, à 8 heures du soir, Salle de comté, 011, Marie Victorin, Verchèrcs Village, comté dc Verchèrcs, P.Q.Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Verchèrcs (Comté dc Verchèrcs), ce 23 novembre 1970.Le secrétaire-trésorier, Philippe Collette, Bureau du secrétaire-trésorier, 1, rue St-Louis, Case postale 250, Verchèrcs, village.Comté de Verchèrcs, P.Q., Téléphone: 583-3564, code 514.37525-o Ville dc Chapais Comté d'Abitibi-Est Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront January 1, 1989.$5,500 January 1, 1990.6,000 January 1, 1991.0,500 Moreover, thc following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balnnec carried over to the fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One lo 10-ycar serial bonds with the balance carried over as 10-year bonds for one purl and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, in the latter terms and conditions.20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than 80,500, and if greater than Ihe latter amount, Ihe said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starling with I lie last years of maturities excluding the maturity of January 1, 1991.However, tenders shall be seul for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in thc eases of Ihe exceptions stipulated herein.Adjudication -hall be made according lo law.The successful tenderer agrees lo pay for Ihe bonds, capital and accrued interest, if any.by certified cheque payable at par at Verchèrcs.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will nol be redeemable by anticipation if ihey are issued serially or serially and as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 80,500 and this surplus only shall Ik-redeemable by anticipation, at par, on January 1st of ench year for the annual amount required lo amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in Ibis notice.Each tender must be accompanied by a ccrl ilied cheque equal to 1% of the amount of thc Issue and must specify whether interest accrued on ihe bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant lo the following by-law: 158 \u2014 $62,000 \u2014 aqueduct, sewers.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Tuesday, December 15, 1970, at 8:00 o'clock p.m.id Ihe County Hall, 611 Marie Viclorin, village of Verchèrcs, county of Verchèrcs, P.Q.The council docs not bind itself to accept 'I\"' highest or any of thc tenders.Verchèrcs (County of Verchèrcs), November 23, 1970.Philippe Colette, Secretary-Treasvrcr.Office of the Secretary-Treasurer, 1.St.Louis Street, Post Office Box 250, Verchèrcs, Village, Countv of Verchèrcs, P.Q.Telephone: 583-3564, code 514.3i525 Town of Chapais County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tender- for bonds\" will be received by the undersigned, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.18 6921 reçues par la soussignée Madame Thérèse Tou-zin, assislante-secréluire-lrésorier.Hotel de Ville, case postale 38, Cliapais, comté d'Abitibi-Est, P.Q., jusqu'à 5.30 heures de l'après-midi, lundi, le 11 décembre 1970, pour l'achat dc §298,500 d'obligations de la ville de Chapais, comté d'Abilibi-Est, datées du 1er janvier 1971 et remboursables par série du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1091 inclusivement, avec intérêt à mi taux non inférieur à 8J-£%, ni supérieur à |)J / ;.payable semi-annucllement les 1er janvier el 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt |Hiil élre le même pour toute rémission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré au lablcau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sent calculé à compter du 1er janvier 1971.Mrs.Thérèse Touzin, Assistant Secretary-Treasurer, Town Hall, Post Ollicc Box 38, Chapais, county of Abitibi-Kasl, P.Q., until 5:30 o'clock p.m., Monday, December 14, 1970, for thc purchase of a bond issue of 8298,500, bonds of the town of Chapais, county of Ahitihi-Eusl, dated January 1.1971 and redeemable serially from January 1, 1972 lo January I, 1991 inclusively, with interest at a rale not less than 8}-2%, nor more than 9) 0%, payable semi-annually on January 1st and July 1st of each year.The rale of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rale be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from January I, 1971.Tableau d'amortissement \u2014 S29S,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er Janvier 1972.815,500 1er Janvier 1973.17,500 1er Janvier 1974.18,500 1er Janvier 1975.19,000 I.r janvier 1976.20,500 1er janvier 1977 .22,000 1er janvier 1978.23,500 1er Janvier 1979.:.25,500 1er Janvier 1980.27,000 1er Janvier 1981.28,500 1er Janvier 1982 .8,500 I.r janvier 1983 .9,000 1er Janvier 1984 .9,500 1er Janvier 1985.10,500 1er Janvier 1986.11,500 1er janvier 1987 .6,000 1er Janvier 19S8.6,000 1er janvier 1989 .6,500 1er Janvier 1990 .6,500 1er Janvier 1991.7,000 Kn plus, les modalités suivantes seulement scrollI considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième aimée.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde rc|x>rté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans ¦vee le solde à terme fixe 20 ans.4 Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et I autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, |Kiur cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront |kis l'Iie pour un montant inférieur à S7.000 et si supérieur à ce dernier montant, cette partie devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, \u2022 I en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1091.Cependant, les soumissions ne devront être Iran-mises (pie pour un seul des modes d'émission ci-haut el ne devront comporter qu'un seul des terme* sauf dans les cas des exceptions notées, '\u2022'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par dièquc visé, payable au pair à Cliibougamau.1-e capital et les intérêts sont payables à Ionics les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la Procédure d'emprunt.Table of redemption \u2014 8298,500 \u2014 20 years Yeur Capital January I, 1972.815,500 January 1, 1973.17,500 January 1, 1974.18,500 Januurv 1, 1975.19,000 Januurv 1, 1976 .20,500 January 1, 1977.22,000 January 1.1978 .23,500 January 1, 1979 .25,500 January 1, 19S0.27,000 January 1, 1981.28,500 January 1, 1982 .8,500 Januurv I.1983 .9,000 January 1.1984 .9,500 Januurv 1, 1985.10,500 January 1, 1986.11,500 Januurv 1, 19S7.0,000 Jnnuarv 1.1988 .6.000 January I, 1989 .0,500 January I, 1990 .6,500 January 1.1991.7,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One to 10-ycar serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One to 15-year serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-year serial bonds with the balance carried over to ten years for one part, and as 20-ycar fixed-term bonds for the other part.However, in the case of the latter method of payment, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be'for an amount less than S7.000, and if greater than the latter amount, said part must only comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, the January 1.1991 maturity being excluded.However, lenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the.bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Chihougumau.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure. 6922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,8 Lcsdites obligations ne seront pas rachetantes par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un moulant supérieur à 87,000 et seul cet excédent sera rnchctablc par anticipation au pair le 1er janvier dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lcsdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 39 \u2014 S147.500 \u2014 renouvellement, d'emprunt; 114 \u2014 855,000 \u2014 fonds de roulement; 115 \u2014 S85.000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 122 \u2014 811,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions scront-ouverlcs et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 14 décembre 1970, à 5.30 heures de l'après-midi.Hôtel de Mlle, case postale 38, Chapais, comté d'Abitibi-Est, P.Q, Le conseil se réserve le droit dc n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chapais (Comté d'Abilibi-Est), ce 20 novembre 1970.L'assislanlc-secrétairc-lrésorier, Madame Thérèse Touzin.Hôtel de Ville, Case postale 38, Chapais (Comté d'Abitibi-Est), P.Q.Téléphone: 775-2512, code S19.37515-0 The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 87,000, and thc surplus only will be red, unable by anticipation, at par, on January 1st of each year for thc annual amount required In amortize the issue, in accordance with the table of maturities of thc issue appearing in this notice.Euch lender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of lin-issue and must specify whether interest accrued on the bonds to thc dale of their delivery is included or not in the price of the tender.Thc said bonds will be issued under the following, by-laws: 39 \u2014 8147,500 \u2014 loan renewal: 11-1 \u2014 855,000 \u2014 working capital; 115 \u2014 885,000 -aqueduct, sewers, roads; 122 \u2014 811,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened at a meeting of the council to be held Monday, December 14, 1970, at 5:30 o'clock p.m., at the Town Hull, Post Office Box 3S, Chapais, countv of Abitihi-East, P.Q.Thc council does not bind itself to accept the highest or any of the lenders.Cliapais (Countv of Abitibi-Eost), November 20, 1970.Mrs.Thérèse Touzin, Assistant Secretary-Treasurer.Town Hall, Post Office Box 38, Chapais (County of Abitibi-East), P.Q.Telephone: 775-2512, code 819.37515 Régie de l'électricité et du gaz Avis public Revision des dispositions du code (J40, actuellement en vigueur, relatives aux installations de gaz canalisés La Régie projette d'adopter un code concernant les installations de gaz canalisés en remplacement des dispositions du code G-40, actuellement en vigueur, relatives à ces mêmes installations.La Régie invite lout manufacturier, distributeur, organisme ou corps public intéressés à prendre connaissance du projet de ce code et à signifier au soussigné, d'ici le 10 décembre 1970, leur intention dc soumettre des représentations qui doivent se limiter aux seules divergences entre le projet de ce code et le code dc l'Association Canadienne dc Normalisation CSA B149-1966 « Installation Code for Gas Burning Appliances and Equipment.» Les intéressés peuvent obtenir immédiatement copie du projet dc ce code, moyennant S10 la copie, à l'adresse suivante: Le Secrétaire, Régie dc l'Électricité et du Gaz, 2100 rue Drummond, Montréal 107, P.Q.Le 25 novembre 1970.37505-O Electricity and Gas Board Public Notice Revision of the provisions of Code G-40, presently in force, in respect of installations for gas distributed through piping systems.Thc Board proposes adopting a Code governing installations for gas distributed through piping systems, replacing the provisions of Code G-40 presently in force, in respect of said installations.Thc Board extends an invitation to every interested manufacturer, distributor, organization or public body to consult the draft of this Code and to notify the undersigned, by December 10, 1970, of their intention to submit representations, which shall be confined to thc differences between the draft of said Code and Standard 11149-1966 \"Installation Code for Gas Burning Appliances and Equipment\" of the Canadian Standards Association.Interested parties may obtain immediately copies of the draft of this Code, at a charge of S10 per copy, at the following address: The Secretary Electricity and Gas Board 2100 Drummond Strccl Montreal 107, P.Q.November 25, 1970.37505-0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 G923 Examen des Agronomes Agronomists Examination Aspirants k l'étude be l'agronomie \u2014 Candidates to tub study of agriculture Tableau contennnt les noms, pronoms, Arc et domicile des aspirants A l'élude de l'agronomie ainsi que le nom dc la dernière institution oti ils ont étudié Table containinR the names, surnames, age and residence of candidates to the study of agriculture and also the name of the last institution where they have studied Noms et prénoms Names and surnames Allaire, Jacques.April.Gaston- Iti.i '.iiurn, René.Bouchard, Carol.Cailchon, Claude.Clark, I).Wayne.Clou 1er, Penis.('., I aux, I'ierre S.A., Dallairc, I'ierre.Poky, Leon.l'omet, .(arques.Glrnnl, Conrad.(\".-din, Guy.Grondin, Julien.Landry, Maurice.Lapointe, Kaynald.Lnrouclie, Laurent.Lecoure, Lis©.Ly, llai-Chau.Mnmnrbnelii, Guy.Mu i-m.Jean-Pierre.Mure.iii-I'oitras, Suzanne.Poincrlcnu, Jacques.1'iilnlte.Prime.Iloclion, André.Roy, Marcel.St-Arnaud, Ililairc.St-J i nues.Dominique.Simard, Hélène.Tremblay, Laval-G.Verge.Hobert.Age 20 39 21 21 24 24 21 39 22 23 24 22 20 22 19 18 21 20 24 25 20 22 19 20 20 24 21 18 19 19 18 Domicile Residence Rang 2, St-David de Falardcau, comté de Dubuc.21, avenue Sle-Genevicve, Quélicc.3855, boul.St-Jean-Baptiste, Ba-gotville, comté de Dubuc.992.rue Simard, St-Ambroisc, comté dc Dubuc.81.dc Provence, Courvillc, Québec 6.Brownbury, Québec.Sl-Odilon, comté de Dorclicstcr.St-Gitlcs, comté de Lotbinière.02.boul.Riviere du Moulin, Clii-coutimi.R.R.1, Abercorn, comté dc Bronte, Saint-Jacques, comté de Montcalm.Saint-Voilier, comté de Bellechasae.Boul.Cantpagna, St-IIenri, comté de Lévis.G808, rue Sulabeny, Lac Méganlic.Saint-André, comté de Kumouraska 153, rang 0, Jonquière.2870, boni.St-Anieet, Bagotvillc, comté de Dubuc.795, 3c rue, Ihervillc.4405, 1ère avenue, Charlesbourg.Université Laval, Ch.0707, Pavillon Parent.198, Stc-Fumillc, Kéiiogami.1397, rue Maric-Victorin, Si-Nicolas, comté de Lévis St-Méthodc de Frontenac.40, boul.15, St-Tite des Caps, comté de Montmorency.2505, Des Hospitalières, Québec 0.3S0, St-Désiré.Black Luke.1100, rue Principale, Ste-Anne do la l'érade.20(12, Mont-Joli.Ste-I-'oy.471, rue Victoria, Bagotvillc.R.R.No 10, Larouclie, comté de Lapointe.1379, avenue Maguirc, Sillery, Québec 0.Institutions Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Montréal.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université McGill.Séminaire St-Gcorgcs de Beaucc.Faculté d'Agriculture Université McGill.l'acuité d'Agriculture Université Laval.Séminaire dc St-Augustiii.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.École Normale Notre-Dame de Foy.CEGEP de Jonquière.Faculté d'Agriculture Université Laval.CEGEP St-Jean sur Richelieu.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.CEGEP deSte-Foy.Faculté d'Agriculture Université Laval.Faculté d'Agriculture Université Laval.Petit Séminaire dc Québec.Montréal 357.le 20 novembre 1970 \u2014 Montreal 357, November 20, 1970.Le secretaire général de La Corporation des Agronomes de la province dc Québec, Théodore Monoeac.Agronome, 1i s l-lS-2-o Secretary General ol La Cor\\ioralion des Agronomes de In prorinec de Québec.Ventes par Shérifs Sheriffs' Sales AVIS PUBLIC, est pur le présent donné que ks TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés onl été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.ABITIBI PUBLIC NOTICE is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Fieri Facias Province de Québec \u2014 District d'Abitibi in- Supérieure, ( \"DANQUE CANADIENNE No 15,898.< O NATIONALE, corpora-v tion légalement constituée, Fieri Facias Province of Québec \u2014 District of Abitibi Superior Court, ( \"DANK CANADIAN NA-No.15,898.< D TIONAL.Ja corporation \\ legally constituted, und hav- 6924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1070, 102' année, n* 1,8 ayant, son siège social dans les cite cl district dc Montréal, demanderesse, t» PAUL GINGRAS, domicilié an 95 rue Allant, Val d'Or, P.Q., défendeur.« Deux emplacements situés à Botirlamaquc, maintemtnl Val d'Or, connus et désignés comme étant les lots numéros trente-trois et trenle-quatre (33 et 34) aux plan et livre de renvoi olliciels de la ville dc lîourlnmnque, avec la résidence y érigée et dépendances.» Pour être vendu au Imreau d'enregistrement au Palais dc Justice d'Amos.le TREIZIÈME jour de JANVIER 1971.à QUATORZE heures cl TRENTE.Le shérif, Bureau du Shérif, Laval Goulet.Amos, le 19 novembre 1970.37527-6 BEAUHARNOIS District dc Reuuhnrnois Cour Supérieure, C \"CRIC McCARTNEV, élcc-No 111GS.) *-> tricien, de la cité dc No 10039.J Cornwall, province d'Ontario, V et y résidant au 007, rue Prcs-eod, et DAME RUBY JEAN MeCARTNEY, ménagère, de la ville de Ornistown, dans le district de Rcauharnois, épouse commune en biens de Willis Holt, journalier du même endroit, ce dernier parti des présentes aux fins d'autoriser son épouse, et DAME GRACE MeCARTNEY, ménagère, dc la cilé de Cornwall, province d'Ontario, et y résidant au 103, Fennel Crescent, épouse séparée dc biens dc Gérald Long, du même endroit, demandeurs, t» EVERETT WILLIAM McCARTNEV.du 1410.rue James, de la cité dc Cornwall, province d'Ontario, défendeur et DAVID WILFRID McCARTNEV, du 42 Casllebor Road, de la ville de Toronto, province d'Ontario, et DAME LAURA McCARTNEV, de la cité de Cornwall, province d'Ontario, y résidant au 115, Fennel Crescent, épouse séparée de biens dc Jack MacDonald, du même endroit, et DAME MAJORIE ELLA McCARTNEV, de la cité de Cornwall, province d'Ontario, y résidant au 1410, rue James.é|k>use séparée dc biens de Colin Ducasse, mis en cause.Les lots numéros un A et un R et un D (1-A-1-H-l-D) dans le sixième rang du canton dc Hinchinbrookc comprenant partie 1-A 5 acres, partie 1-E 46 acres, partie 1-1) 54 acres le tout formant une superficie dc 105 acres bornés au sud par ce qui reste du lot 1-D et l-B au nord par ce qui reste du lot 1-D et le lot l-C, à l'ouest par le numéro 2-A et à l'est par la ligne dc division entre le comté d'Huntingdon cl celui de Château-guay, avec bâtisses y érigées.Le lot numéro deux R (2-B) dans ledit sixième rang dudit canton dc Hinchinbrookc comprenant 100 acres bonté au sud par le chemin public à l'ouest par le chemin public, à l'est par le lot 2-A tous desdits rang et canton, avec bâtisses y érigées.Lesdits lots 1-A, 1-E, 1-1), 2-B tous faisant partie dc la succession dc feu William James McCartney et dc la succession de feue Dame Jean Hamilton Tannahill, sa première épouse.Pour être vendu séparément au bureau d'enregistrement de la division dc Huntingdon, à Hun- ing its head office in the city and district f Montreal, plaintiff, rs PAUL GINGRAS, d.i- tiled at 95 Allard Street, Val d'Or, P.Q., defendant.\"Two emplacements situated in liourlamoqtic, now Nul d'Or, known and designated as being lots numbers thirty-three and thirty-four (33 and 34) on official plan ami book of reference for thc town of Botirluinnqiic, with the dwelling house thereon erected and dependencies.\" To be sold at the Regislrv Office at the Court House, of Amos, thc THIRTEENTH da\\ of JANUARY, 1971, at TWO THIRTY o'clock in the afternoon.Laval Goulet, Sheriffs Office, Sheriff.Amos, November 19, 1970.37\"i27 BEAUHARNOIS District of Bcauharnois Suix-rior Court, ( \"CRIC McCARTNEV, dec-No.11168.J ¦L' trician, of the city of No.10039.\"j Cornwall, province of Ontario, ' and residing there at.607 Prescod Street, and DAME RUBY JEAN .McCARTNEV, housewife, of the town of Onus-town, in thc district of Rcaidiarnois, wife common as to properly of Willis Bolt, labourer of the same place, the latter fonns part of the presents for thc purjiosc of authorizing his wife, and DAME GRACE McCARTNEV.housewife, .J the city of Cornwall, province of Ontario, and residing there at 103 Fennel Crescent, wife separate as lo pro]>crtv of Gérard Long, of the same place, plaintiffs, r.i EVERETT WILLIAM McCARTNEV, of 1410 James Street, of the city of Cornwall, province of Ontario, defendant, and DAVID WILFRID McCARTNEV, of 42 Cus-tlebor Road, of thc city of Toronto, province of Ontario, and DAME LAURA MeCARTNEY, of thc city of Cornwall, province of Ontario, ami residing there at 115 Fennel Crescent, wife separate as to property of Jack MacDonald, of the same plncc, and* DAME MAJORIE ELLA MeCARTNEY, of the city of Cornwall, province of Ontario, and residing there at 1410 James Street, wife separate as to property of Colin Du-cassc, mis en cause.Lots numbers one A and one B and one l> (1-A, l-B, 1-D) in the sixth range of the township of Hinchinbrookc comprising part 1-A 5 acres, part l-B 40 acres, part 1-1) 54 acres, the whole comprising an area of 105 acres bounded in the south by what remains of lot 1-1) and l-B in Ihe north by what remains of lot 1-1) and lot l-C.m the west by number 2-A and in the cast by tie boundary line between thc county of Huntingdon and that of Châtcaugnay, with the buildings thereon erected Lot number two R (2-B) in the said sixth range of the said township of Hinchinbrookc comprising 100 acres bounded in the south by the public road, in the west by thc public road, in the east by lot 2-A, all the said range and township, wilh the buildings thereon erected.Thc said lots 1-A, l-B, 1-D and 2-B comprising part of thc estate of William James McCartney, deceased, and thc estate of Dame Jean Hamilton Tannahill, deceased, his first wife.To be sold separately at the registration office of the Division ot Huntingdon, at Huntingdon, the QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.A8 0925 ling Ion, le TRENTIÈME jour de DÉCEM-11 RIO 1970, ù DIX heures dc l'avant-niidi et DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Lucien Piumeau.\u2022 Snlaberry dc Valleyfield, ce 18c jour dc novembre 1970.37470-o L A BELL E Canada \u2014 Province de Québec < our Supérieure \u2014 District de Montréal t fiHARTER CREDIT COR-N\" 750-510.\\ ^ PORATTON, demandercs-\\ se, vs LÉO-PAUL SABOURIN, résidant et domicilié à 572, nie Du Portage, M oui-Lan lier, comté de Labellc, Québec, défendeur.l.e lot de terre numéro quinze cent cinquante et un (1551) au cadastre officiel dc la ville de Mont-Laurier, tel que le tout se trouve actuellement, avec bâtisses y érigées, circonstances et dé| tendances.» Pour être vendu, au bureau d'enregistrement au palais dc justice à Mont-Laurier, comté et district de Labellc, LUNDI, le ONZIÈME jour de JANVIER 1971, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif Le shérif intérimaire, Mont-Laurier, Roland Mattk.ee 17 novembre 1970.37425-o THIRTIETH day of DECEMRER, 1970, at TEN a.m.and at TEN-THIRTY a.m.J.Lucien Phimeau, Office Sheriff, Assistant Sheriff.Salabcrry de Valleyfield, this 18th day of November, 1970.37476 LABELL E Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( CHARTER CREDIT COR-No.750-510.< ^ PORATION, plaintiff, «v» v LÉO-PAUL SAROURIN, residing and domiciled at 572 Du Portage Street, Mont-Lauricr, county of Lavclle, Québec, defendant.\"A lot of land number fifteen hundred and fifty-one (1551) on the official cadastre of the town of Mont-Laurier, as the whole subsists at present, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.\" To lie sold at the registration office at the Court House at Mont-Lauricr, county and district of Labellc, MONDAY, the ELEVENTH day of JANUARY, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Roland Mattk, Mont-Laurier, Acting Sheriff.November 17, 1970.37425 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris t 'our Supérieure \u2014 District dc Montréal I A RMAND GAGNON, compta-Xo 777-000.\\ blé, en sa qualité de syndic, V demeurant et domicilié au numéro SOI Tour dc la Bourse, Place Victoria, des cité et district de Montréal, demandeur, vs NUNZIO TROMBINO, demeurant et domieilié au 12,798 rue Louis Vcuillot, Montréal-Nord, défendeur.Désignation Lu emplacement ayant front sur la rue Louis Vcuillot, en la cité de Montréal-Nord, connu et désigné comme étant le lot numéro trente dc la sul » livision du lot originaire numéro onze (11-30) aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse (lu Sault-au-RécoUct, mesurant trente-cinq pieds (35) de largeur sur cent quarante-cinq pieds et trois dixièmes de pied (145.3') de profondeur dans sa jigne nord-ouest, et cent quarante-six pieds et trois dixièmes de pied (146.3') de profondeur dans sa ligne sud-est et contenant en superficie cinq mille cent trois pieds carrés (5,103') mesure anglaise.> Avec une maison dc deux étages y érigée portail! le numéro civique 12,798 dc la rue Louis \\i uillot, dont le mur latéral sud-est est mitoyen avec l'emplacement voisin.Ainsi (pie le tout se trouve présentement, avec tous droits y inhérents sans exception, ni réserve.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais dc Justice, en la ville de Montréal, le VINGT-NEUVIÈME jour ||c DECEMBRE 1970, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 16 novembre 1970.37519-0 MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal l A RMAND GAGNON, accoun-No.777-000.-J ¦*» tant, in bis capacity us trustee residing and domiciled at 804 Stock Exchange Tower, Victoria Square, in the city and district of Montreal, plaintiff, VS NUNZIO TROMBINO, residing and domiciled at 12,798 Louis Vcuillot Street, Montreal North, defendant.Designation \"An emplacement fronting on Louis Vcuillot Street, in thc city of Montreal North, known and designated as being lot number thirty of the subdivision of original lot number eleven (11-30) on the official plan and in the book of reference of thc parish of Sault-au-Récollct, measuring thirty-five feet (35') in width by one hundred and forty-five feet and three tenths of a foot (145.3') in depth on its northwest line, and one hundred and forty-six feet and three tenths of a foot (146.3') in depth on its southeast line and containing in area five thousand one hundred and three square feet (5,103') English measure.\" With a two-storey house erected thereon bearing civic number 12,798 Louis Vcuillot Street, the lateral southeast wall of which is common lo the neighbouring emplacement.As the whole is presently found, with the rights related thereto without exception nor reservation.To be sold at the Ollicc of the Prothonotary, Room #129, at the Old Court House, in the city of Montreal, on the TWENTY-NINTH day of DECEMBER, 1970, at ELEVEN o'clock in the moming.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 16, 1970.37519 G92G GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, w° 1,8 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District dc Québec t /COMMISSION DES ACCI-No 10270.< ^ .DENTS DU TRAVAIL DE v QUEBEC, cor])s politique et incorporé ayant son principal bureau d'affaires à 225 Est, Grande-Allée, à Québec, P.Q., deninn-deresse, vs JOLY BUNGALOW LIMITÉE, corps politique et incorporé ayant son siège social à Sic-Rose de Laval, -17 nie Archambault, Sle-Rosc de Laval, ville de Laval, défenderesse.Désignation Un emplacement situé en la ville de Laval (Auteuil) se décrivant comme suit: un terrain vacant comme élant le lot numéro cent vingt-huit de la subdivision officielle du lot numéro originaire quarante (40-128) au cadastre de la paroisse de Sic-Rose: un emplacement vacant connu comme étant une partie du loi numéro quarante (Plie 40) du cadastre de la paroisse Stc-Rosc, tel emplacement ayant front à lu 9c Avenue, Parc des Erables.Mesurant quatre cent trente pieds (430') de façade, par la profondeur dudit emplacement et contenant en superficie cinquante sept mille quatre cent douze pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (57,412.5') le tout à la mesure anglaise et plus ou moins.Tel emplacement étant borné vers le nord, par des parties du lot 40, vers le sud par d'autres parties du lot 40, vers l'ouest par la 9e Avenue, et vers l'est, par la ligne.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Laval, 155 Boulevard Je Me Souviens, en la cité dc Laval, le VINGT-NEUVIÈME jour dc DECEMBRE 1970, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Mahtix.Montréal, 10 novembre 1970.37518-0 Fieri Facias de Terris Cour Provinciale \u2014 District dc Montreal { T3 ONALD NEWMAN, contrac-No 28S-546A iV leur, dc la cité de Côte St- ' Luc, district dc Montréal, et faisant, affaire sous le nom et style de * Ron Aluminium Co.> à 7925 Kingsley Rond, demandeur, vs MARCEL ARCHAMBAULT, de St-Çons-tant, district dc Montréal, cl résidant au 120 rue St-Jacques, défendeur.« Qu'un certain emplacement sur la rue Sl-Jacqucs dc la cité dc St-Constant, division d'enregistrement de Laprairic, connu et désigné comme la subdivision cent vingt-six (120) du loi originaire numéro deux cent, quarante-sept (247) dans le plan et livre olliciel de références de la paroisse de St-Constant et avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 120, rue St-.Iacqucs.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laprairic.214 St-Ignace, en la ville de Laprairic, le TRENTIÈME jour de DÉCEMBRE 1970, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Mahtix.Montréal, le 18 novembre 1970.37520-O Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T ES PLACEMENTS AUDAX No 557-078X INC., corps politique légalc- V ment constitué et ayant place d'alfaircs en les cité et district de Montréal, demanderesse; vs MARCEL GOETHALS, domi- Ficri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Québec ( r\\UÛmC WORKMEN'S COM-No.1G27G.-j V ONALD NEWMAN, conlrnc-No.288-546.-< tor, of the city of Cote v Saint-Luc, district of Montreal, and doing business under the name and style ol \"Ron Aluminium Co.\", at 7025 Kingsley Road, plaintiff, vs MARCEL ARCHAMBAULT, of Saint-Constant, district of Montreal, and residing at 126 Saint-Jacques Street, defendant.\"A certain emplacement on Saint-Jacques Street, ill the city of Saint-Constant.Registration Division of Laprairic, known and designated as being subdivision one hundred and twenty-six (120) of original lot number two hundred and forty-seven (247) on the official plan and booh \"f reference of thc parish of Saint-Constant and with thc immovable thereon erected, bearing number 120 Saint-Jacques Street.\" To be sold at.the Registry Ollicc in the county of Laprairic, 214 Saint-Ignace, in thc town \"f Laprairic.on the THIRTIETH day of DECEMBER, 1970, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Maiitin.Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 18, 1970.37520 Fien Facias de Terris Superior Court\u2014District of Montreal C T ES PLACEMENTS AUDAX No.557-078.J-M INC., body politic legally ' incorporated and having its head office in the city and district of Moid real, plaintiff; versus MARCEL GOETHALS, domi- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Korcmbcr 28, 1970, Vol.102, A'o.AS 0927 cilié cl rendant à Rivière-dcs-Prairies, district dc Montréal, défendeur.l'n certain emplacement connu et désigné com.étant la subdivision trente-trois du lot originaire quatre-vingt-treize (93-33) et lu subdivision deux cent un du lot originaire quatre-vingt-Iniil (88-201) aux plan et livre dc renvoi officiels de l.i paroisse de St-Vincent de Paul, avec bâtisse de\u2014us érigée portant, le numéro civique 950 rue Klieiinc-Parent à Laval.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval.155 boulevard Je Me Solium-, en la cité dc Laval, le TRENTIÈME jour de DÉCEMBRE 1970, à ONZE heures dc l'avant-midi.Hunan du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Maktix.Montréal, 18 novembre 1970.37521-0 cilcri and residing at Itivière-des-Prairics, district of Montreal, defendant.\"A certain emplacement known and designated as being subdivision Ihirly-lhrcc of original lot ninety-threc (93-33) and subdivision two hundred and one of original lot cithly-eighl (88-201) on the official plan and book of reference of the parish of Saint-Vincent dc Paul, with building thereon erected bearing civic number 930 Elicn-nc-Parcnt Street, in Laval.\" To be sold at the Registry Ollicc of the county of Laval, 155 Je Me Souviens Boulevard, in the city of Laval, on thc THIRTIETH day of DECEMBER, 1970, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriffs Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 18, 1970.37521 QUÉBEC Fieri Faeias de Terris Québec, & savoir:/ CIIELL CANADA LTD, Cour Provinciale,I O corps politique légale-No 3S-211.j ment constitué, ayant une '.place d'affaires dans les cité cl district dc Quebec, t» ROMÉO THIBAULT, domieilié et résidant à 925, 8c Avenue, app.1, Québec, district de Québec.¦ l.e lot -111-51 du cadastre officiel dc la municipalité dc Charlesbourg, de figure irrégulière, Iniriie au sud-est par le lot No 411-A (rue) au sud-ouest par le lot No 411-52, vers l'ouest par un tributaire de la rivière du Berger, au nord-est par le lot No 411-45, mesurant 50 pieds au sud-est, 80 pieds au sud-ouest, 80 pieds au norri-est, contenant en superficie 4,250 pieds carrés, mesure anglaise, avec circonstances et dépendances.l.e lot 111-42 du cadastre officiel de la municipalité de Charlesbourg, borné au sud-est par le lot No ii 1-A (rue), au sud-ouest par le lot No 111-45, au nord-ouest pur le lot No 411-00, nu nord-est le lot No 411-41, mesurant 50 pieds de largeur par 100 pieds dc profondeur, contenant en superficie 5,000 pieds, mesure iinglaisc avec circonstances cl dépendances.l.e lui 411-45 du cadastre officiel de la municipalité de Charlesbourg, borné au sud-est par le lot No 4 11-A (nie), vers l'ouest par un tributaire gauche dc la rivière du Berger, nu nord-est par le loi No 411-51, mesurant 50 pieds dc largeur par IIKI pieds de profondeur au nord-est et 80 pieds au sud-ouest, contenant en superficie 4,740 pieds, mesure anglaise, avec circonstances et dépendances.* lour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, avenue Chauveau, Québec, le TRENTIEME jour dc DÉCEMBRE 1970, à DIX heures dc l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 24 novembre 1970.37517-o Fieri Facias dc Terris Québec, à savoir:/ pLZÉAR VERREAULT ' our Supérieure,! J-' LTÉE, corps politique et No 4S18.\\ incorporé légalement consti-, ' tué ayant une place d'affaires \u2022i 372.\", Sl-Hcnri, Québec, district de Québec, rs Mme SIMONE F.LAGACÉ, épouse séparée de bien- do M.Lagucé, faisant affaires sous lu raison sociale de « Développement Montmorency Ç-ur.à C.p.40, Beauimrt, Québec, district de Québec.QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( CIIELL CANADA LTD, Provincial Court, ) & body politic legally con-No.38-211.j slilulcd, having a place of V business in the city and district of Québec, rs ROMÉO THIBAULT, domiciled and residing at 925, 8th Avenue, Apt.1, Québec, district of Québec.\"Lot No.411-51 of the official cadastre of the municipality of Charlesbourg, of irregular dimensions, bounded in the southeast by lot No.411-A (street), in the southwest by lot No.411-52, towards thc west by a tributary of the du Berger river, in thc northeast by lot No.411-45, measuring 50 feet in the southeast, SO feel, in the southwest, 86 feet in thc northeast, comprising an area of 4,250 square feel, English measure, with circumstances and dependencies.Lot No 411-42 on the official cadastre of the municipality of Charlesbourg, bounded in thc southeast by lot No.411-A (street) in, the southwest by lot No.411-45, in the northwest by lot No.411-60, in the northeast by lot No.411-41, measuring 50 feet wide by 100 feel deep, comprising an area of 5,000 feet, English measure, with circumstances ami dc|iendencics.Lot No.411-45 on the official cadastre of the municipality of Charlesbourg, bounded in the southeast by lot No.411-A (street), towards the west by a left tributary of the du Berger river, in thc northeast by lot No.411-51, measuring 50 feet wide by 100 feet deep in the northeast and 86 feet in thc southwest, comprising an area of 4,740 feet, English measure, with circumstances and dependencies.\" To be sold at the Registration Office of Québec, Chauveau Avenue, Québec, the THIRTIETH day of DECEMBER, 1970, at TEN o'clock in the morning.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 24, 1970.37517 Fieri Facias de Terris Québec, to wit:( \"RLZEAR VERREAULT Superior Court, ) LTÉE, body politic and No 4S18.J corporate legally incorporated, ' having a place of business at 3725 St-Hcnri, Québec, district of Québec, nr Mrs.SIMONE F.LAGACÉ, wife separate as to property of Mr.Lagacé, carrying on business under the name of \"Développement Montmorency Enr.\", at P.O.Box 40, Beauport, Québec, district of Quebec. 0928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 novembre 1970, 102' année, »° 18 « Le loi S14-3S du cadastre olliciel dc la paroisse dc Hcuuporl, île figure rectangulaire; borné vers le nord-est par le loi No 814-39, par le sud-est par une partie non-subdivisée du lot No 814, vers le sud-ouest par le lot No 814-37 et vers le nord-ouest par le Chemin Ste-Thérèse.Mesurant soixante-sept pieds (07') en front sur le chemin Ste-Thérèse par cent huit pieds et dix |hiuccs (108M0\") de profondeur au nord-est.Contenant en superficie sept mille deux cent quatre-vingt-douze pieds carrés (7,292 p.c.) mesures anglaises.Le lot S14-39 du cadastre olliciel de la paroisse de Bcauport, de ligure rectangulaire; borné vers le nord-est par le lot No 814-40, par le sud-est par une partie non-subdivisée du lot No SI4, vers le sud-ouest par le lot No 814-38 et vers le nord-ouest par le Chemin Sic-Thérèse.Mesurant soixante-sept pieds (07') de largeur en front sur le Chemin Ste-Thérèse par cent huit pieds et dix pouces (IOS'10\") de profondeur au nord-est.Contenant en superficie sept mille deux cent, quatre-vingt-douze pieds carrés (7,292 p.c.) mesures anglaises.Le lot S14-40 du cadastre olliciel de la paroisse dc lirauport, de figure rectangulaire: borné vers le nord-est et le sud-est par une partie non-subdivisée du lot.No 814, vers le sud-ouest par le lot.No 814-39 cl vers le nord-ouest par le < 'hemin Ste-Thérèse.Mesurant soixante-sept pieds (07') île largeur en front sur le Chemin Ste-Thérèse par cent huit pieds et dix pouces (108'10\") de profondeur au nord-est.Contenant en superficie sept mille deux cent quatre-vingt-douze pieds carrés (7,292 p.c.) mesures anglaises.Le lot S14-44 du cadastre olliciel de la paroisse dc Bcauport.dc figure irrégulière: borné vers le nord-est par le lot No 814-45, vers le sud-est par le lot No S14-47 (Hue), vers le sud-ouest par le lot No 814-43 el vers le nord-ouest par les lots S14-41 et S14-42.Mesurant huil pieds et un pouce (S'1\") plus soixante-trois pieds et.huit pOUCCS (G3'S\") en front au sud-est sur la rue portant le No 814-47, soixante-onze pieds (71') de largeur en arrière au nord-ouest, sur une profondeur au sud-ouest de cent un pieds et (plaire pouces (101 '4\") et au nord-est de cent sept pieds et quatre pouces (107'4\").Contenant en superficie sept mille quatre cents pieds carrés (7,400 p.c.) mesures anglaises.Le loi 814-45 du cadastre olliciel de la paroisse de Bcauport, de figure irrégulière: borné vers le nord-est par le loi No 814-40 vers le sud-est par le lot No 814-47 (Hue), vers le sud-oucsl par le lot No 814-44, vers le nord-ouest par le lot No 814-41 et vers le nord par une partie non-subdivisée du loi No 814.Mesurant soixante-quatorze pieds et neuf pouces (74'9\") en front au sud-est sur la rue portant le No S14-47, sept pieds et six pouces (7'0\") de largeur en arrière au nord-ouest plus soixante-douze pieds et quatre pouces (\"2'4\"), sur une profondeur au sud-ouest dc cent sept pieds et quatre pouces (107'4\") et au nord-est quatre-vingt-huit pieds (88').Contenant en superficie sept mille deux cents pieds carrés (7,200 p.c.) mesures anglaises.> Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, avenue Chauveau, Québec, le TREN-TIÈME jour dc DECEMBRE 1970, à DIX heures de l'avaiil-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 24 novembre 1970.37503-o \"Lot 814-38 of the official cadastre of Iho parish of Beauport, of a rectangular figure: I num.(led on thc northeast by lot No.814-39, soul beast by an unsubdivided part of lot No.814, un southwest by lot No.814-37 and on thc northwest by Ste-Thérèse Road.Measuring sixty-seven feel (67') in fronton Ste-Thérèse Road by one hundred and eight feet and ten inches (108'10\") in depth on the northeast.Containing in area seven thousand two hundred and ninety-two square feel (7,292 sq.ft.) English measure.Lot 814-39 of the official cadastre of the parish of Bcati|)ort, of a rectangular figure: bounded on the northeast by lot No.814-40, southeast by an unsubdivided part of lot No.814, on the southwest by lot No.814-38 and on the northwest by Ste-Thérèse Road.Measuring sixty-seven feci (67') in width in front on Ste-Thérèse Road by one hundred and eight feet and len inches (108'K)\") in depth on the northeast.Containing in area seven thousand two hundred and ninety-two square feet (7,292 sq.ft.) English measure.Lot 814-40 of the official cadastre of the parish of Bcauport, of a rectangular figure: bounded on the northeast and southeast by an unsulxlividcd pari of lot No.814, on the southwest by loi No.814-39 and on the northwest by Ste-Thérèse Road.Measuring sixty-seven feet (07') in width in front on Ste-Thérèse Road by one hundred and eight feet and ten inches (IOS'10\") in depth on the northeast.Containing in area seven thousand two hundred and ninety-two square feet (7,292 sq.ft.) English measure.Lot 814-44 of the official cadastre of the parish of Beauport, of an irregular figure: bounded on the northeast by lot No.814-45, on the soul beast by lot.No.814-47 (Street), on thc southwest by lot No.814-43 and on the northwest by loi «814-41 and 814-42.Measuring eight feet and one inch (S'l\") plus sixty-three feet and eight inches (03'8\") in front on the southeast on the si net bearing No.814-47, seventy-one feet (71') in width in thc rear on the northwest, by n depth on the southwest of one hundred and one feel and four inches (101'4\") and on the nortltcusl one hundred and seven feet and four inches (197' I\").Containing in area seven thousand four hundred square feet (7,400 sq.ft.) English measure.Lot 814-45 of the official cadastre of the parish of Bcauport, of an irregular figure; bounded on thc northeast by lot No.814-46, on the soul head by lot No.814-47 (Street), on thc southwest by lot No.814-44, on thc northwest by lot No.814-41 and on thc north by an unsubdivided part of lot No.814.Measuring seventy-four feel and nine inches (74'9\") in front on thc soutlieiisl on the street Waring No.814-47, seven feet.I six inches (7'6\") in width in thc rear on the northwest plus seventy-two feet and four inches (72'4\"), by a depth on the southwest of_on« hundred and seven feet and four inches ' 11 1 and on the northeast eighty-eight feet So); Containing in area seven thousand two hundred square feet (7,200 sq.ft.) English measure.To be sold at thc Québec Registry Office, Chauveau Avenue, Québec, on the THIRTII.III day of DECEMBER, 1970, at TEN o'clock in the morning.Raymond Hais-, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 24, 1970.3780! QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 0929 Fieri Facias de Terris Québec, A savoir: l TD E DIS C O C A N A1) A Cour Provinciale, J LTD., corps politique No 50-768.J et incorporé légalement cons-V titué, ayant une place d'affaire» à Québec, district dc Québec, contre GEORGES COVA, domicilié et résidant à 27S2 Ville-Marie, Stc-Fôy, district de Québec.\"l.e lot .\"193-83 du cadastre officiel de la paroisse de Stc-Fôy, dc figure irrégulière borné au nord-ouest p;ir le lot 393-75, au nord-est par le lot 393-S4, au sud-est par le lot 393-87 (rue) et au sud-ouest j»ar le lot 393-82; mesurant soixante-dix pieds cl cinq dixièmes (70'.5) au nord-ouest, quatre-vingt-onze pieds et quatre dixièmes i!)!'.I) au nord-est, soixante-dix pieds et six dixièmes (70'.6) au sud-est et quulrc-vingt-qualrozc pieds (94') au sud-ouest.Contenant en superficie six mille cinq cent trente pieds carrés, mesure anglaise (0,530 p.c), avec circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement île Québec, Avenue Chauveau, Québec, le TRENTIÈME jour «le DÉCEMBRE 1970, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 24 novembre 1970.37516-0 SAGUENAY De Terris ( anada \u2014 Province de Québec District dc Québec & Sagucnay tour Supérieure, ( T A CAISSE POPULAIRE Xo 4523.< -L- DE ST-ROMUALD t D'ETCHEMIN société régie |iar la loi des Cuisses d'Epargne et dc crédit, ayant son siège sociul à Sl-Romunld, district dc Québec, demanderesse, es MME GERMAIN IIOII.Y.domiciliée à 1345 rue Commerciale, St-Romuald, ilislricl dc Québec, défenderesse.\u2022 l'n emplacement situé à Haie St-Paul.avec liAtisscs dessus construites, mesurant quatre-vingt-seize pieds de largeur en front et à la profondeur, sur cent vingt-cinq pieds dc profondeur, mesure anglaise, désigné comme étant composé d'une partie du lot numéro neuf cent trente-six il'lie 936) au cadastre officiel de la paroisse «le la Haie Si-Paul, borné en front vers le nord par le chemin public, actuellement la rue Ste-Annc, en profondeur vers le sud et à l'ouest par le terrain de ( 'lis.Bcnj.Simard sur ledit lot 936 et à l'est par le terrain restant à la venderesse sur le même lot 036.Tel que délimité.» Pour Être vendu au bureau du régistrateur à Unie Sl-Piml.comté de Charlevoix.VENDREDI, le N KI \\ I È.M E jour du mois de JAN VIER 1971, i' I>1X heures de l'avant-midi.Ix shérif adjoint.Bureau du Shérif, Bertrand Savard.l.a Malbaie, le 19 novembre 1970.37477-o TERREBONNE f 'anada \u2014 Province de Québec ( onr Supérieure \u2014 District dc Terrebonne (TVME GERTRUDE BUE-No 62,310.4 xJ CHEL, célibataire majeure, l domiciliée à ville de Laval, district «c Montréal, demanderesse; et WILLIAM MAR PIN, domicilié autrefois à Lachute, district Fieri Facias dc Terris.Québec, to wit: ( T5 EDI SCO C A N A D A Provincial Court, ' *V LTD., body politic and No.56-768.1 legally incorporated, having \\ a place of business in Québec, district of Québec, venue GEORGES COVA, domiciled and residing at 27S2, Ville-Marie, St.Foy, district of Québec.\"Lot 393-83 on the official cadastre of the parish of St.Foy, of irregular figure, bounded on the north-west by lot 393-75, on thc north-east by lot 393-84, on the south-east by lot 393-87 (street) and on the south-west by lot 393-82; measuring seventy feet and five tenths of a foot (70'.5) on the north-west, ninety-one feet and four tenths of a foot (91.4') on the north-east, seventy feet and six tenths of a foot (70.0') on the southeast and ninety-four feet (94'), on the south-west.Having a surface area of six thousand five hundred unci thirty square feet, English measure (6,530 sq.ft.) with circumstances and dependencies.To bo sold at the Québec Registry Office, Chauveau Avenue, Québec, on the THIRTIETH day of DECEMBER, 1970, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec-, November 24, 1970.37516 SAGUENAY De Terris ('anada \u2014 Province of Québec District of Québec & Sagucnay Superior Court, ( T A CAISSE POPULAIRE No.4523.< J-' DE ST-ROMUALD l D'ETCHEMIN, a company governed by the Savings and Credit Unions Act.having its head office at St-Romulad, district, of Québec, plaintiff, vs MRS.GERMAIN BOILY, domiciled at 1345 Commercial Street, St-Ro-iiiuaId.district of Québec, defendant.\"A lot situated ut Bay St.Paul, with the buildings thereon constructed, measuring ninety-six feet wide in front and in depth, by one hundred and twenty-five feet deep, English measure, designated as being pari of lot number nine hundred and thirty-six (Part 936) cm the official cadastre of Bay St.Paul parish, bounded in front towards the north by the public road, at present St.Anne street, in depth towards the south and the west by the land belonging to CliS.Benj.Simard on the said lot.936 and towards the cast by the land belonging lo the woman selling on the same lot 936.As demarcated.\" To be sold at the office of the registrar at Bay St.Paul, Charlevoix County, FRIDAY, thc NINTH day of the month of JANUARY, 1971, at TEN a.m.Bertrand Savard, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.La Malbaic, November 19, 1970.37477 TERREBONNE ('anada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne (TVME GERTRUDE BUE-No.62.310.-J J-/ CHEL, spinster of the full t age of majority, domiciled in the town of Laval, district of Montreal, plaintiff; vs WILLIAM MARTIN, formerly domiciled in 6030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 novembre 1970, 102' année, n° 1,8 dc Terrebonne, et maintenant à Ville LaSalle, district de Montréal, défendeur.Avis de vcnle L'immeuble ci-après désigné et en la possession du défondeur, savoir: * Ce certain emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse dc Saint-Jérusalem d'Argcntcuil, comme formant partie du lot numéro deux cent trente-deux (plie 232), mesurant quatre-vingt-six pieds de profondeur sur une largeur de quatre-vingt-douze pieds et trente-trois centièmes; borné au nord par le chemin principal, au sud par la plantation du gouvernement, à l'est par une propriété appartenant à James Mair et à l'ouest par une propriété appartenant à Mme Alex Doig, sans aucune bâtisse dessus érigée, avec un droit de passage le long de la ligne separative sur le côté nord du chemin public, de la propriété du vendeur et celle dc Dame M.Eleanor Wood; ledit droit de passage est présentement accordé afin d'atteindre la grève dc la rivière du Nord.Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes y attachées et dont l'acheteur se déclare satisfait.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil.situé à -130 rue Grace, Lachute.JEUDI, le SEPTIÈME jour tic JANVIER 1071 a DEUX heures dc l'après-midi.< Conditions : comptant.Le shérif intérimaire, Bureau du Shérif, Gaiiiiiki.i.k Foiiixki.i.ë.Sl-Jérôme, le 20 novembre 1970.3752S-o Lachute district of Terrebonne, and now in town of LaSalle, district of Montreal, defendant.Sol ice of sale The hereinafter designated immovable and in the possession of the defendant, to wit: \"That certain emplacement known and design-natcd on the official plan and in the book of reference of thc parish of St.Jérusalem d'Argenteuil as forming part of the lot number l\\v« hundred and thirty-two (pt.232) measuring eighty-six feet in depth by a width on ninety, two feet and thirty-three hundredths; bounded north by the Main Road, south by the Government plantation, cast by a property belonging to James Mair and west by a property l)clonging to Mrs.Alex Doig.without any building thereon erected, with a right of way along the division line on the north side of the public highway of the property of the vendor and that of l'aine M.Eleanor Wood; the said right of way i* hereby granted in order to reach the shore of North River.As the whole now subsists with all the servitudes which may be attached whereto and wherewith the purchaser declares himself I\" he content.\" To be sold at thc registry ollicc for the comity of Argentcuil situated at 430 Grâce Street.Lachute.THURSDAY, the SEVENTH day of JANUARY, 1971.at TWO o'clock in the after-noon.Conditions: cash.Gauuiki.i.i: Fouiixki.i.i:.Sheriff's Office, Acting Sheriff.St.Jérôme, November 20, 1970.::7V2s I X HEX No 411 ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS IN COU SCI 1.410S \u2014 Commission de Police du Québec, adoption du règlement numéro cinq (ô) relatif aux uniformes qui peuvent être portés par les policiers municipaux.6S56 410S \u2014 Québec Police ( 'ommission, passing of by-law number five (5) relating to the uniforms and badges which may be worn by municipal policemen.6S58 4217 \u2014 Habitation familiale (S.R.Q.1904, Chapitre 110 et amendements), modification nu règlement adopté.0854 4217 \u2014 Family Housing (R.S.Q.1904, Chapter 111) and amendments), amendment to the regulation adopted.0951 \u20221314 \u2014 Réduction du montant de la rente el du coût des travaux requis payables par Gnmu- chc Exploration & Mining Co.Ltd.OS03 4314 \u2014 Reduction in thc amount of the rental and the coast of the required work payable by thc Gamache Exploration & Mining Co.Ltd.BS63 4328 \u2014 Bois ouvré, Québec (Mollifications au décret) (Corrections à l'Arrêté en conseil 3921 du 28 octobre 1070).OS63 4328 \u2014 Wrought Wood, Québec (Amendments lo the decree) (Corrections lo the Order in Council 3921 of October 28, 1070).''^ ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIOSS Association coopérative Gamier (Som-Samc ch.).0898 Association coopérative d'habitation dc Maniwaki (Dissolution).9898 AVIS DIVERS MISCELL.iSEOUS SOTICES Board of Notaries of thc Province of Québec (Code of Professional Ethics).l|St>' Board of Notaries of the Province of Québec (Trust Accounting).087Jj Chambre des notaires du Québec (Code d'éthique professionnel).088 Chambre des notaires du Québec (Comptabilité en fidéicommis).08711 Estate of Ilyman Burdmaii (Benefit of inventory).'j^i Montréal, ville-city (Rachat d'obligalions-Redemption of bonds).OSO\" Succession Ilyman Burdmnn (Bénéfice d'inventaire).\"Soi QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 28, 1970, Vol.102, No.1,8 6931 CHANGEMENT DE NOM Qoitandes: Bcnsoussan, Albert Joseph.Lichtig, Peter.Nikolof, William.ltosovitc.il, Harold Hyman.Y'ce, Kuo Y an.Loi du CHANGE OF NAME ACT Applications: 6S92 0S91 6891 0891 0S92 CVISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS Caisse d'entraide économique de St-Jcun et Iberville (correction).6900 COMMISSION COMMISSION De Géographie Geographical Commission Jnci |ues-Rousseau.6893 Mont Raoul-Blanchard.0S93 Péninsule d'Ungava.0892 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES EXTRA-PROVINCIAL COMPANIES Licenses: l'criiitx: lia les ville International Corporation.6S92 Slanray (.'orporation.6892 COM PAG NI ES \u2014 COMPANIES 1.01 DES ACT Demandes d'abandon Applied lion s for de l'hurle Surrender of Charier lllais (J.A.) & Fils ltéc.6S74 Candiac Golf & Country Club (1967) 1.1,1.6873 ('lui.de golf Candiac (1967) lice.6873 Corrivcau (Patrice) Oxygen Inc.6874 Corporation dc l'école d'aide sociale de Sherbrooke (La).6873 Direct Supply Co.Ltd.6874 Forrest Realties Limited.6S73 Immeubles d'Assises Itée (Les).6876 l.ae Ouareau Development Co.Ltd.6S75 Landlac Realty Corp.Ltd.6874 Motel Metro Ltd.6S75 Realty Appraisals Ltd.6874 Restaurant le campeur inc.6875 Solov limitée (La).6873 Sydney Monk Sales Ltd.6S75 Teresa Realty Corp.6875 Mandes de choix Amel ltéc (Les).6874 Vincent Frères ltéc.6875 Winford Investment Corp.6876 Dissoutes Dissolved Association de la récréation et des parcs du Québec (L').6864 Association des marchands d'alimentation de Montréal inc.6864 Association of Food Merchants of Montreal Inc.6864 ( tor Rentals of Québec Ltd.6864 Classy Belt Inc.6864 < à immutcrs Shop Inc.(Thc).6865 Crescent Land Corp.6865 ' lenstar Holdings Limited.6865 Ln Vigie.6865 Loisirs dc la vallée de l'or inc.(Les).6S65 Marwill Realties Inc.6865 Modern Planning Mills Inc.6866 Mountain Holdings Ltd.6866 Plage La Liberté inc.6866 Ramapti inc.6S66 Recreation and Parks Association of Québec (The).6864 Savoie (S.), limitée.6866 Sherbrooke Demolition Inc.6S00 Vivian Fashions Inc.6866 Divers Miscellaneous Association des parents des élèves du Conservatoire de musique de Trois-Rivières (L') (Règl.-By-laws).6881 Bcaudin Nobcrt inc.(Dir.).6876 Bravo Investment Inc.(Dir.).6879 Camping Fontainebleau inc.(Dir.).6877 Candiac Development Corporation (Dir.).0876 Candiac Nurseries Ltd.(Dir.).6876 Centre dc loilirs Coeur Immaculé de Marie inc.(Règl.-By-laws).6879 Centre dc loisirs Ste-Jcannc d'Arc (Sherbrooke) inc.(Nom-Nume ch.).6877 Clinique Roy-Rousseau (Règl.-By-laws) 6881 Construction modique Lachcnaic liée (Dir.).6S82 Corporation du centre Berlhelet-Sl-Yal- lier inc.(Règl.-Bu-laws).6S76 Corporation de la villa Dion (La).6877 Couillard Entreprises (Division Construction) inc.(Noni-Naïuech.).6880 DBM Industries Limited (Dir.).0881 Double-E Electric Inc.(Dir.).6876 Eastern (.'anada Packaging Limited (Dir.)._.6S77 Fédération nationale des auberges de jeunesse du Québec inc.(Règl.).6878 Foyer Dorval (Dir.).6877 Galeries du C'a]» liée (Les) (Nom-Naine ch.).6S80 Hôpital St-Joscph de Thctford Mines (Règl.-By-laws).6S82 Hôpital St-Joscph de Trois-Rivières (Régi.-By-laws).6S80 Hôpital Sl-Lambcrt (Convalescents) (Règl.-By-laws).^.0877 Hull Cemetery Company (Règl.-Bi/- laws).6878 Industries DBM limitée (Dir.).6881 Lafortune & Gagné limitée (Dir.).6878 Loren Construction Co.Ltd.(Dir.)____ 687S Martin Draperies Inc.(Dir.).6878 Molson (Québec) limitée (Dir.)____.6878 Monique Neckwear Mfg.Co.Ltd.(Dir.) 6879 Montreal Camera Club (Règl.-By-laws).6SS0 National Federation of Québec Youth Hostels Inc.(By-laws).6878 Puinchaud (Georges) inc.(Dir.) .6878 Quebec-Ontario Frcightways Inc.(Norn-Name ch.).6880 Régional ltéc (Le) (Dir.).6880 St.Gcorges's School of Montreal, Inc.(Règl.-By-laws).6S79 Scie Chapais inc.(La) (Dir.).6S81 Scroc inc.(Dir.).6879 Service des loisirs St-Vincent-de-Paul de Montréal (Règl.-By-laws).6877 Sorccom inc.(Dir.).6879 V.D.General Metal Works Ltd.(Dir.).6879 V.D.O.Productions Inc.(Nom-Name ch.).6S81 Wally Trading Company Limited (Dir.) 6879 Whitlock Golf & Country Club (Règl.- By-laws).6S81 0932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 88 novembre 1970, 102' année, n° 1,S Lettres patentes Letters Paient A P A Jonquière limitée.0792 A.R.Cafétéria inc.0792 Académie Normand Hudon inc.(L') .0793 Advertising Agency Ltd.0813 Aéroport du comté de Lévis liée.0793 Alma Varieties Inc.6793 Appartements Plein Cieil itée (Les) .6794 Aquarius Restaurant Bar Salon Inc.0842 Arsenc's Service Stations LUI.0794 Association d'entraide de Ste-Anne dc Beaupré inc.0794 Association des marchands de la place Lcvasscur inc.(L').0795 Association des scouts de lTmmaculée- Conccption de Granby inc.(L').079S Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes dc l'école Barclay.6819 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Central Park.0795 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Bedford 6797 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes dc l'école Lachinc Rapids.6796 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes de l'école Russell.0796 Association (Hellénique) des parents Grecs-Orthodoxes dc l'école Sinclair Laird.0796 Association des Psychotechnicicns du Québec.0797 Aubcrtin Industries Inc.6824 Auteuil sport inc.6798 Autos Paul Audet Itée.079S Auxiliaires dc l'hôpital du Haut-Richelieu inc.(Les).0799 Bargelletti Ltd.6799 Béliveau (J.C.) Itée.6S00 Rcrk (Michael) Inc.6800 Bcrnicr (Ernest) inc.6S00 Bolduc (Edouard) inc.6S01 Boulangerie d'Asbcstos inc.(La).6S01 Boutique V-21-S inc.6801 Bracbrook Cleaners (Kirkland) Inc.6802 Budget Fuels Inc.6821 C.A.I., Comité d'accueil aux Immigrants inc.6802 Canadian Tiron Chemical Corporation.0802 Centre dc gestion polyvalent du Québec (C.G.P.Q.) liée.0803 Centre des loisirs de Scotstown.6803 Chauret (Léo) construction inc.6803 Chiffonnerie L.G.Itée (La).0804 Cie tl'entretien J.K.Itée (La).6825 Ciné-parc des 4 Chemins inc.6804 Club d'aviation Vénus inc.6804 Club de golf dc Murdochevillc inc.6805 Club Moto-Neige Franquelin inc.6805 Club moto-neige les Multicolores de St- Césaire inc (Le).6806 Club social de Richmond.6806 Club social tic Ste-Marie inc.6S06 Commerce Delag limitée.6S12 Compagnie de gestion dc la Matapédia ltéc (La).6807 Complex Chemicals (Eastern) Ltd.6807 Conciergerie Paul inc.(La).6807 Conseil d'habitation économique Beau- portltée.0808 Conseil Québécois de l'Environnement inc.680S Construction Val des Arbres ltéc.6808 Corporation des maîtres-démolisseurs du Québec inc.(La).6809 Corporation du Festival d'automne de Rimouski inc.(La).Iis09 Corrivcau (L.G.) inc.6S1Q Crofton Realties Inc.(i>ln D.T.S.inc.,is'u Dallairc Records Distributions Ltd.(iS12 David-Florence Holdings Ltd.(Ml Deb - Jay Importers Ltd.6811 Dec (Lilly) Creations Ltd.6S11 Delag Trading Limited.6812 Dclux Gold Jewelry Mfg.Co.Ltd.0S12 Distributions de discpics Dallairc ltéc (Les).6812 Duvcrnay Iron Works Inc.6813 Edstar Textiles Inc.6813 Elizabeth (Jane) Fashion.0813 Elsona Realties Inc.6814 Entreprises Éloi inc.(Les).0814 Entreprises Paul Leblanc inc.(Les).OS 14 Entreprises Rodrigue Buillargcon inc.(Les)._.6815 Fédération sportive et culturelle du 1 làiim Rouge inc.6815 Ferme Mathieu inc.6815 Fcrminox inc.liMli Ferraro Barber Shops Inc.OSl.i Fiber Glass T.M.(1970) Inc.6816 Fibre de verre T.M.(1970) inc.6816 Forest Auto Body Inc.6817 G.H.P.inc.6817 Garage B.Turgcon inc.(1817 Gestion Lnfaille Itée.6818 Globcnsky Sports Marine Inc.6S1S Grufilmax inc.6818 (ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Barclay School.6819 (ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Bedford School.0797 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Central Park School.0795 Greek Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Lachinc Rapids School.0796 (ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Russell School-.0796 (ireck Orthodox (Hellenic) Association of Parents of Sinclair Laird School.0796 Grimard (J.V.) & associés inc.6819 Hallmark Knits Ltd.0819 Hébert & Légaré inc.6S20 Hellenic Social Development Corp.(Montreal).«820 Hôtel Motel Amico inc.6820 Hôtel-Motel La Brindc, inc.0821 Huard (Pierre) ltéc.0821 Huiles Budget inc.0821 Immeubles G.G.B.inc.(Les).0822 Immeubles Hudon ltéc (Les).0822 Immeubles Otis inc.(Les).0822 Importations Narbonne inc.0823 Imprimerie Lasallc inc.0823 Industrial Gear Mfg.Inc.6823 Industries Aubertin inc.(Les).0S24 Institut des jambes du Québec inc.6824 Investissements Monte Carlo inc.(Les).0S24 Investisso inc.082a J.K.Maintenance Co.Ltd.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.