Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 février 1971, samedi 27 (no 9)
[" 103» ANN ICE VOL.103 fJUEBEC Gazette officielle à Quebec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE N° 9 1951 Québec, samedi 29 février 1971 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.3° Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.5° L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazette officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec, a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.Québec, Saturday, February 29, 1971 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are apayablc in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Quebec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon ; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear irj.A later .edition.Moreover, The Québec Official P-ut5h§ben.reserves the right to defer publication of certain documents because; of their length or for administrative reasons.m -V UÊdiUur officiel du Québec, ROCH LEFEBVRE.Québec Official Publisher GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 février 1971, 103' année, n° 9 8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre $20; du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rocu Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 37883\u20141-52-0 8.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation: §4 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscriptions periods : From January 1st to December 31st, S20; April 1st to December 31st, S15 and July 1st to December 31st, S10.N.B.\u2014Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion ; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Rocu Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30,1969 37883\u2014l-52-o Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec 4, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints, or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec official Gazette Téléphone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec 4, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Pontage paid-in-cash\u2014Third olasa matter (permit No.107) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 1953 Lettres patentes Agence Kcet inc.Kect Agency Inc.l.i- ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de décembre 1970, constituant en corporation: SU lima n Kect, homme d'affaires, Danielle Carrier, épouse dudit Stillman Keet, tous deux de 530, boulevard Ste-Annc, Beauport, et Helen Kcet, veuve de Lewis Irving, 700, 74c rue, Char-lesbourg, ces deux dernières ménagères, pour les objet-, suivants: Exploiter des territoires et des clubs de pêche et de chasse, sous le nom de « Agence Kcet inc.\u2014 Keet Agency Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 100 actions ordinaires de 8100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Beauport, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5510-1970 Rend Albert inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation: René Albert, industriel, Aline Morency, ménagère, épouse dudit René Albert, tous deux de 11, France, Villeneuve, et Marc Morency, mécanicien, 115, 42c Rue ouest, Clîarlcsbourg, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de marchandises et articles fabriqués totalement ou en partie de métaux ou bois, sous le nom de « René Albert inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 97-1971 Alkny Real Estate Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de décembre 1970, constituant en corporation: È.Samuel Berger, Abraham Slawner et Paul B.Cohen, tous trois avocats, du 1010 ouest, rue Sainte-Catherine, app.410, Montréal, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Alkay Real Estate Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Letters Patent Agence Keet inc.Kcet Agency Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Stillman Kcet, businessman, Danielle Carrier, wife of the said Stillman Kcet, both of 530 St.Anne Boulevard, Beauport, and Helen Kect, widow of Lewis Irving, 700, 74th Street, Charlcsbourg, the latter two housewives, for the following purposes: To develop fishing and hunting territories and clubs, under the name of \"Agence Keet inc.\u2014 Kcet Agency Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 100 common shares of S100 each and 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Beauport, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5510-1970 Rene Albert inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: René Albert, industrialist.Aline Morency, housewife, wife of said René Albert, both of 11 France, Villeneuve, and Marc Morency, mechanic, 115, 42nd Street, West, Charlcsbourg, for the following purposes: To manufacture and deal in merchandise and articles made in whole or in part of metal or wood, under the name of \"René Albert inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of S10 each and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 97-1971 Alkay Real Estate Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: E.Samuel Berger, Abraham Slawncr and Paul B.Cohen, all three advocates, of 1010 St.Catherine Street West, Apt.410, Montreal, for the following purposes : To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Alkay Real Estate Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of a par value of SI each and 20,000 preferred shares of a par value of $1 each. GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 1954 Le siège social de la compagnie est à Montreal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5740-1970 Aluminium Fleur de Lys ltée Le ministre des institutions financières,' compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Irwin Schnaiberg, 6550 ouest, Sherbrooke, app.618, Montréal, Hyman Laddic Scluiaibcrg, 7460, Kingslcy, tous deux avocats, et Sam Stolovitsky, administrateur, 5751, rue Rand, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de bardeaux, fenêtres et matériaux de construction en aluminium, sous le nom de « Aluminium Fleur de Lys ltée », avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5612-1970 Artisanat Idéal inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Gaétan Cloutier, 7321, rue des Lynx, Jacques Tanguay, tous deux hommes d'affaires, et Mireille Tanguay, lemme d'affaires, épouse dudit Jacques Tanguay, ces deux derniers de 7162, Place des Renards, tous trois d'Orsainville, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de vêtements et de produits d'artisanat de tous genres, sous le nom de « Artisanat Idéal inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Orsainville, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5616-1970 Association des enseignants diplômés de Belgique au Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Alain Stieve-naert, Jeannine Rorive, épouse dudit Alain Stievenaert, tous deux de 843, Décolles, Jacques Rorive, Christianne Peltier, épouse dudit Jacques Rorive, tous deux de 1076, Dupas, tous quatre de Longueuil, Raymond Lambo- The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5740-1970 Aluminium Fleur de Lys ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Irwin Schnaiberg, 6550 Sherbrooke West, Apt.618, Montreal, Hyman Laddie Schnaiberg, 7460 Kingsley, both advocates, and Sam Stolovitsky, executive, 5751 Rand Street, the latter two of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To manufacture and deal in aluminium siding, windows and building supplies, under the name of \"Aluminium Fleur de Lys ltée\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 38854-0 5612-1970 Artisanat Idéal inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gaétan Cloutier, 7321 des Lynx Street, Jacques Tanguay, both businessmen, and Mireille Tanguay, businesswoman, wife of said Jacques Tanguay, the latter two of 7162 Place des Renards, all three of Orsainville, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing and handicraft foods of all kinds, under the name of \"Artisanat Idéal inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and into 300 preferred shores of 8100 each.The head office of the company is at Orsainville, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5616-1970 Association des enseignants diplômés de Belgique au Québec inc.Notice is given that under Part LLT of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Alain Stievenaert, Jeannine Rorive, wife of said Alain Stievenaert, both of 843 Decelles, Jacques Rorive, Christianne Peltier, wife of said Jacques Rorive, both of 1076 Dupas, all four of Longueuil, Raymond Lambo- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 relie, Marie-Thérèse Collin, épouse dudit Raymond Lamborelle, tous deux de 5, St-Philippe, Saint-Jean-d'lberville, Valentin Rienckens, 10375, St-Denis,- Edmond Pauly, 11833, James Morrice, tous deux de Montréal, Jules Mazy, 1355, Châteauguay, Saint-Bruno-de-Montarville, et Jean-François Mostert, 103, avenue Mont-Bruno, Sainte-Julie, tous professeurs, pour les objets suivants: L'entraide, la défense et le développement des intérêts culturels, intellectuels, sociaux et professionnels des membres, sous le nom de « Association des enseignants diplômés de Belgique au Québec inc.» .Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $100,000.Le siège social de la corporation est 3312, Place Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5680-1970 Association des Clubs de Motos-Neige de l'Estrie Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Claude Laliberté, vendeur, 540, Bertrant, Yves Dumont, vérificateur, 5555, rue Triquet, et Robert Boulay, notaire, 1075, rue Rouleau, tous trois de Saint-Hyacinthe, pour les objets suivants: Promouvoir le sport de la moto-neige, sous le nom de « Association des Clubs de Motos-Neige de l'Estrie ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de $50,000.Le siège social de la corporation est à Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5497-1970 Association des propriétaires de St-Bruno de Montarville inc.St.Bruno de Montarville Property Owners' Association Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Henri Proulx, analyste de gestion, 1275, rue Dufrost, Gilles Deslauricrs, psycho-éducateur, 1225, Vignau, et Claude Limoges, vendeur, 1285, rue Dufrost, tous trois de Saint-Bruno-de-Montarville, pour les objets suivants: Promouvoir les intérêts culturels et sociaux des membres, sous le nom de « Association des propriétaires de St-Bruno de Montarville inc.\u2014 St.Bruno de Montarville Property Owners' Association Inc.\".1955 relie, Marie-Thérèse Collin, wife of said Raymond Lamborelle, both of 5 St-Philippe, Saint-Jean-dTber-ville, Valentin Rienckens, 10375 St-Denis, Edmond Pauly, 11833 James Morrice, both of Montreal, Jules Mazy, 1355 Châteauguay, Saint-Bruno-de-Montarville, and Jean-François Mostert, 103 Mont-Bruno Avenue, Sainte-Julic, all professors, for the following purposes: The defence and development of the cultural, intellectual, social and professional interests of the members together with mutual assistance, under the name of \"Association des enseignants diplômés de Belgique au Québec inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $100,000.The head office of the corporation is at 3312 Victoria Square, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5680-1970 Association des Clubs de Motos-Neigc dc l'Estrie Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Claude Laliberté, salesman, 540 Bertrant, Yves Dumont, checker, 5555 Triquct Street, and Robert Boulay, notary, 1075 Rouleau Street, all three of Saint-Hyacinthe, for the following purposes: To promote snowmobiling, under the name of \"Association des Clubs de Motos-Neige de l'Estrie\".The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation may acquire or possess is $50,000.The head office of the corporation is at Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5497-1970 Association des propriétaires de St-Bruno de Montarville inc.St.Bruno dc Montarville Property Owners' Association Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Henri Proulx, analyst in management, 1275 Dufrost Street, Gilles Deslauriers, psycho-educator, 1225 Vignau, and Claude Limoges, salesman, 1285 Dufrost Street, all three of Saint-Bruno-de-Montarville, for the following purposes: To promote the cultural and social interests of its members, under the name of \"Association des propriétaires de St-Bruno de Montarville inc.\u2014 St.Bruno de Montarville Property Owners' Association Inc.\". 1956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108' année, n\" 9 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 830,000.Le siège social dc la corporation est à Saint-Bruno-dc-Montarville, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54-o 5290-1970 Association des vendeurs professionnels d'automobiles de I lui lord inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Rémi Roy, 628, boulevard Ouellet, Serge Drouin, 1165, Notre-Dame nord, tous deux de ïhetford Mines, et Alcédor Pomerlcnu, Saint-Antoinc-dc-Pontbriand, tous trois vendeurs, pour les objets suivants: Etudier, promouvoir, protéger et développer dc toute manière les intérêts économiques, sociaux et professionnels des membres, sous le nom de « Association des vendeurs professionnels d'automobiles dc Thetford inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est dc 8100,000.Le siège social dc la corporation est à Thetford Mines, district judiciaire de Mégantic.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54-0 5720-1970 L'Association dc tir h la Volée de l'Est Québécois; (ATVEQ) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour dc janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Raymond Faille, administrateur, 3304, Place de la Monncric, No 1, Marcel Bouchard, représentant, 754, des Mélèzes, No 1, tous deux de Saintc-Foy, et Serge Levasseur, analyste en informatique, 1125, Murray, Québec, pour les objets suivants: Promouvoir le sport du tir à la volée, sous le nom de « L'Association dc tir à la Volée de l'Est Québécois; (ATVEQ) ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de la corporation est 754, des Mélèzes, app.1, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5420-1970 The amount to which is to be limited the real estate which the corporation may acquire or possess is $30,000.The head office of the corporation is at Saint-Bruno-de-Montarville, judicial district of Montreal.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5290-1970 Association des vendeurs professionnels d'automobiles dc Thetford inc.Notice is given that under Part ILT of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Rémi Roy, 62S Oucllct boulevard, Serge Drouin, 1165 Notre-Dame north, both of Thetford Mines, and Alcédor Pomerleau, Saint-Antoinc-dc-Pontbriand, all three salesmen, for the following purposes: To study, promote, protect and develop in every way the economic, social and professional interests of its members, under the name of \"Association des vendeurs professionnels d'automobiles le Thetford inc.\".The amount to which is to be limited the annual income derived from the real estate which the corporation may acquire or possess is 8100,000.The head office of the corporation is at Thetford Mines, judicial district of Mégantic.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5720-1970 L'Association de tir it la Volée de l'Est Québécois; (ATVEQ) Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Raymond Faille, administrator, 3304 Place de la Monncric, No.1, Marcel Bouchard, representative, 754 des Mélèzes, No.1, both of St.Foy, and Serge Levasseur, analyst in data-processing, 1125 Murray, Québec, for the following purposes: To promote skcet shooting, under the name of \"L'Association de tir à la Volée de l'Est Québécois; (ATVEQ)\".The amount to which is to which is to be limited the value of the immovable property which the corporation may acquire or possess if 8100,000.The head office of the corporation is at 754, des Mélèzes, Apt.1, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5420-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Association Petrcllcso du Quebec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Giorgio Ruscitto, concierge, 6040, Houel, Suint-Léonard, Raffacle Viglione, épicier, 6845, 44c Avenue, et Ales-sandro Amoroso, opérateur, 7393, 6c Avenue, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: ' Venir en aide à tous ceux qui pourront se trouver avec des problèmes de nature sociale, syndicale ou administrative, sous le nom dc * Association Petrellesc du Québec inc.».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et poséder la corporation, est de S40,000.Le siège social dc la corporation est 5446, Jean-Talon est, Saint-Léonard, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-u 5705-1970 Association provinciale des chevaux miniulures Provincial Association of Miniature Horses Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5c jour dc janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions : Léo Tourigny, épicier-boucher, Paul Blanchcltc, briquetcur, tous deux de Bécancour, Guy Durand, entrepreneur, 291, Montée Gagnon, Herman Thcrrien, menuisier, 177, Ste-Morie, tous deux dc Saintc-Anne-des-Plaincs, Jean Lachapcllc, paysagiste, 109S9, Drapeau, Montréal, Jacques Lachapelle, facteur, 11036, Lamourcux, Montréal-Nord, Roméo Duludc, cultivateur, André Robidoux, gérant, tous deux dc Saint-Rémi, Ange-Émilc Robillurd, entrepreneur, 100, rang Stc-Julic, Charles-Émilc Bouchard, fonctionnaire, 105, Mande-ville, tous deux dc Joliette, Pierrc-A.Paquin, hôtelier, 1039, avenue Théoret, Robert Prévost, commerçant, 1943, Bord du Lac, tous deux dc Saint-Raphaé'l-dc-l'Ile-Bizard, Daniel Couture, vendeur, Vcnisc-cn-Québec, et James O'Cain, gérant, Saint-Grégoire, pour les objets suivants: Étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes manières les intérêts culturels, sociaux ou matériels des membres, sous le nom dc « Association provinciale des chevaux miniatures \u2014 Provincial Association of Miniature Horses ».Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $25,000.Le siège social dc la corporation est à Saint-Grégoire, district judiciaire de Nicolet.Le sous-ministre des instituions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 38-1971 1957 Association Petrcllcse du Quebec inc.Notice is given that under Part ILT of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Giorgio Ruscitto, janitor, 604O Houcl, Saint-Léonard, Rofl'aele Viglione, grocer, 6845, 44th Avenue, and Alessundro Amoroso, operator, 7393, 6th Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To help those persons with problems of a social or administrative nature or problems relating to trade unions, under the name of \"Association Petrcllcse du Québec inc.\".The amount to which is to be limited the annual income derived from the immovable property which the corporation can acquire or possess is $40,000.The head office of the corporation is at 5446 Jean-Talon East, Saint-Léonard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5705-1970 Association provinciale des chevaux miniatures Provincial Association of Miniature Horses Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Léo Tourigny, grocer-butcher, Paul Blanchettc, brick-layer, both of Bécancour, Guy Durand, contractor, 291 Montée Gagnon, Herman Therrien, carpenter, 177 Ste-Maric, both of Sainte-Anne-des-Plaines, Jean Lachapcllc, landscape gardener, 10989 Drapeau, Montreal, Jacques Lachapcllc, mailman, 11036 Lamourcux, Montreal-North, Roméo Duludc, farmer, André Robidoux, manager, both of Saint-Rémi, Ange-Émile Robillard, contractor, 100 Stc-Julie range, Charlcs-Émilc Bouchard, civil servant, 105 Mandevillc, both of Jolicttc, Pierre-A.Paquin, hotel-keeper, 1039 Théoret Avenue, Robert Prévost, merchant, 1943 Bord du Lac, both of Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, Daniel Couture, salesman, Venise-cn-Québec, and James O'Cain, manager, Saint-Grégoire, for the following purposes: To study, promote, protect and develop in every way the cultural, social and material interests of its members, under the name of \"Association provinciale des chevaux miniatures \u2014 Provincial Association of Miniature Horses ».The amount to which is to be limied the real estate which the corporation may acquire or possess is $25,000.The head office of the corporation is at Saint-Grégoire, judicial district of Nicolet.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 38-1971 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 87 février 1971, 103' année, n\" 9 1958 Association régionale de tennis dc l'Estrie inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour dc janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Denis Dumas, ingénieur, 482, Rachel, Réjean Boulet, vendeur, 259, rue Dcnison, et André Thibault, professeur, 705, rue St-François, tous trois dc Granby, pour les objets suivants : Former et exploiter une association sportive et promouvoir en particulier le sport du tennis, sous le nom de « Association régionale dc tennis dc l'Estrie inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $40,000.Le siège social dc la corporation est 328, Principale, suite 25, Granby, district judiciaire de Bedford.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 117-1971 Association sportive de St-Adclmc Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Ravmond Gagné, cultivateur, Henri Marquis, journalier, Êmilien Gagné, opérateur, Claude Marquis, aide cuisinier, et Etienne Thibeault, commis de bureau, tous de Saint-Adelme, pour les objets suivants: Promouvoir les sports en général et en particulier les sports du ballon-balai, ballon-volant, balle-molle, et soccer, sous le nom de « Association sportive de St-Adelme ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de S25.000.Le siège social de la corporation est à Saint-Adelme, district judiciaire de Rimouski.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 2299-1970 Astrobclix sports inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 19e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Gilles Gagnon, marchand, La Sarre, Guy Rousseau, administrateur, 44, Notre-Dame est, et Roger Messier, hôtelier, 2417, Cadillac, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de marchandises et plus spécialement de tous les articles concernant les sports, sous le nom de « Astrobelix sports inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de $10 chacune.Association régionale dc tennis dc PEstrie inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Denis Dumas, engineer, 482 Rachel, Réjean Boulet, salesman, 259 Denison Street, and André Thibault, professor, 705 St-François Street, all three of Granby, for the following purposes: To form and operate a sports association and to promote tennis in particular, under the name of \"Association régionale de tennis de l'Estrie inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $40,000.The head office of the corporation is at 328 Main, Suite 25, Granby, judicial district of Bedford.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Compagnies and Cooperatives.38854 117-1971 Association sportive dc St-Adelmc Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Raymond Gagné, farmer, Henri Marquis, labourer, Êmilien Gagné, operator, Claude Marquis, assistant cook, and Etienne Thibeault, office clerk, all of Saint-Adelme, for the following purposes: To promote sports in general and broomball, volleyball, Softball and soccer in particular, under the name of \"Association sportive de St-Anselme.\" The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $25,000.The head office of the corporation is at Saint-Adelme, judicial district of Rimouski.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 2299-1970 Astrobclix sports inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 19th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gilles Gagnon, merchant, La Sarre, Guy Rousseau, administrator, 44 Notre-Dame East, and Roger Messier, hotel-keeper, 2417 Cadillac, the latter two of Montreal, for the following purposes: To deal in all kinds of merchandise and in particular sports articles, under the name of \"Astrobelix sports inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le siège social de la compagnie est à La Sarre, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 255-1971 Auberge dc Jeunesse dc Rivicre-du-Loup Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Bclzilc, directeur du service d'équipement, 5, Desjardins, Gilles Dubé, coordonnatcur, 133, Laval, app.31, Valèrc Gagnon, directeur du service aux étudiants, 116, St-André, Yvan Morin, prêtre, 154, Fraser, Yvon Morin, directeur général, 10, des Chauf-faillcs, et Roméo Bossinotte, échevin, 35, St-Paul, tous six de Rivière-dù-Loup, pour les objets suivants: Établir un centre d'accueil dc la jeunesse, sous le nom de « Auberge de Jeunesse dc Rivièrc-du-Loup ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8500,000.Le siège social dc la corporation est à Rivière-du-Loup, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 3343-1970 Bcrnicr, Garon & associés inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pierre Garon, courtier en assurances, Yvette Paradis, ménagère, épouse dudit Pierre Garon, tous deux de 8185, Ire Avenue, Gilles Bernier, courtier en assurances, et Louise Poulin, ménagère, épouse dudit Gilles Bernier, ces deux derniers de 8525, Place du Gouverneur, tous quatre de Charlesbourg, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom dc « Bernier, Garon et associés inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 15,000 actions ordinaires de 810 chacune et en 5,000 actions privilégiées dc 810 chacune.Le siège social de la compagnie est 8167, Ire Avenue, Charlesbourg, district judiciaire dc Québec.Ije sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5748-1970 Harry Bloom Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Lawrence Glazer, avocat, 5753, 1959 The head office of the company is at La Sarre, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperaties.38854 255-1971 Auberge de Jeunesse de Rivicrc-du-Loup Notice is given that under Part IH of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert Bclzile, head of equipment, 5 Dcsjardins, Gilles Dubé, coordinator, 133 Laval, Apt.31 Valère Gagnon, director of \"service aux étudiants\", 116 St-André, Yvan Morin, priest, 154 Fraser, Yvon Morin, director, 10 des Chauffaillcs, and Roméo Bossinotte, alderman, 35 St-Paul, all six of Rivièrc-du-Loup, for the following purposes: To set up a welcome bureau for youth, under the name of \"Auberge de Jeunesse dc Rivière-du-Loup\".The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation can acquire or possess is 8500,000.The head office of the corporation is at Rivière-du-Loup, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 3343-1970 Bernier, Garon & associés inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Garon, insurance broker, Yvette Paradis, housewife, wife of said Pierre Garon, both of 8185, 1st Avenue, Gilles Bernier, insurance broker, and Louise Poulin, housewife, wife of said Gilles Bernier, the latter two of 8525 du Gouverneur Place, all four of Charlcsbourg, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Bernier, Garon et associés inc.\", with a total capital stock of 8200,000 divided into 15,000 common shares of 810 each and 5,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 8167,1st Avenue, Charlesbourg, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5748-1970 Harry Bloom Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Lawrence Glazer, advocate, 5753 West- 1960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n' 9 Westminster, Juidi Friedman, fille majeure, 870, Wiseman, et Jean-M.Guy, 1117, Saint-Mathieu, ces deux dernières secrétaires, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce d'automobiles neuves et d'occasions et de véhicules de toutes sortes, d'embarcations, moteurs et dc toutes sortes dc moyens de transport, dc même que des pièces et accessoires qui sy rattachent, sous le nom de « Harry Bloom Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est au 9125, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5763-1970 Hon Ton Cleaners Inc.Nettoyeurs Bon Ton inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour d'août 1970, constituant en corporation: James II.Denmead, Aline Denmcad, épouse dudit James H.Denmcad, tous deux administrateurs, du 875, rue Cardinal, et Germain Demers, commis, 877, rue Cardinal, tous trois de Saint-Laurent, pour les objets suivants: S'établir nettoyeurs, presseurs, teinturiers, buandiers et faire la réparation de vêtements, tissus, articles et ameublement dc maison, sous le nom dc « Bon Ton Cleaners Inc.\u2014 Nettoyeurs Bon Ton inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 300 actions privilégiées dc $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 4161 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-mitiislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 3444-1970 Broadway Automobile Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jean Olive Goldthorp, secrétaire, épouse de Jolm Larsen, 250, 51e Avenue, Lachine, Harry William Goldthorp, administrateur, 7550A, Broadway, et Victor James Goldthorp, 8887, boulevard Lasallc, ces deux derniers de Lasalle, pour les objets suivants: Faire le commerce de véhicules automobiles, camions, pièces de moteurs, avions, moteurs d'avions, canots automobiles, radios, réfrigérateurs, bicyclettes, motocyclettes et accessoires, sous le nom de « Broadway Automobile Ltd.», avec un capital total de 8100,000, minster, Juidi Friedman, spinster, 870 Wiseman, and Jean-M.Guy, 1117 St-Matthew, the latter two secretaries, all three of Montreal, for the following purposes : To deal in new and used auto and motor vehicles of all kinds, boats, motors and in general any type of conveyance including all parts and accessories thereto, under the name of \"Harry Bloom Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of a par value of 81 each and 30,000 preferred shares of a par value of SI each.The head office of the company is at 9125 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5763-1970 Bon Ton Cleaners Inc.Nettoyeurs Bon Ton inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of August, 1970, have been issued by the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James H.Denmcad, Aline Denmead, wife of the said James H.Denmcad, both administrators, of 875 Cardinal Street, and Germain Demers, clerk, 877 Cardinal Street, all three of Saint-Laurent, for the following purposes: To carry on business as cleaners, presscrs, dyers, laundcrers and repairers of clothing, fabrics, goods and household furnishings, under the name of \"Bon Ton Cleaners Inc.\u2014 Nettoyeurs Bon Ton inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 4161 St.Catherine Street West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 3444-1970 Broadway Automobile Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean Olive Goldthorp, secretary, wife of John Larsen, 250, 51st Avenue, Lachinc, Harry William Goldthorp, administrator, 7550A Broadway, and Victor James Goldthorp, 8887 Lasalle Boulevard, the latter two of Lasalle, for the following purposes: To deal in motor cars, motor trucks, motor parts, aircraft, aircraft motors, motor boats, radios, refrigerators, bicycles, motorcycles and accessories, under the name of \"Broadway Automobile Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 70,000 common QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 divisé en 70,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc SI chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lasalle, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 , 5633-1970 Marcel Bruncllc & fils ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Richard Hébert, notaire, 1450, 12e Avenue, app.204, Armandc Dupré, ménagère, épouse dc Marcel Bruncllc, et Rénald Bruncllc, courtier en assurances, ces deux derniers de 1073, 16c Avenue, tous trois dc Pointc-aux-Treinbles, pour les objets suivants: Faire affaires comme agents et courtiers en assurance, sous le nom de « Marcel Bruncllc & fils ltée », avec un capital total «le S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc 810 chacune et en 2,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 1073, 16e Avenue, Pointe-aux-Trembles, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 25-1971 C.& D.Data Systems Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Maximilien Polak, 7897, chemin Wavcll, Côte Saint-Luc, Harvey M.Cooperstone, 1448, Beverley Crescent, Laval, tous deux avocats, Aline Beaulicu, 3801, Cavendish, Montréal, et Diane Malboeuf, S495, boulevard Lasalle, Lasalle, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Faire le commerce dc fiches et formules, dc systèmes, de machinerie et d'équipement dc toutes sortes pour la comptabilité et les affaires, sous le nom de « C.& D.Data Systems Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de 810 chacune et 3,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phiuppe Bouchard.38854 162-1971 Cammi Investments Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première 1961 shares of a par value of SI each and 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at Lasalle, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5633-1970 -Marcel Bruncllc & fils ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard Hébert, notary, 1450, 12th Avenue, Apt.204, Armandc Dupré, housewife, wife of Marcel Brunelle, and Rénald Bruncllc, insurance broker, the latter two of 1073, 16th Avenue, all three of Pointeaux-Trembles, for the following purposes: To carry on business as insurance agents and brokers, under the name of \"Marcel Brunelle & fils ltée\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1073, 16th Avenue, Pointc-aux-Tremblcs, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 25-1971 C.& D.Data Systems Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maximilien Polak, 7897 Wavell Road, Côte Saint-Luc, Harvey M.Cooperstone, 1448 Beverley Crescent, Laval, both advocates.Aline Beaulicu, 3801 Cavendish, Montreal, and Diane Malbocuf, 8495 Lasalle Boulevard, Lasalle, the latter two secretaries, spinsters, for the following purposes: To deal in accounting and business forms, systems, machinery and equipment of all kinds, under the name of \"C.& D.Data Systems Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 162-1971 Cammi Investments Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of De- 1962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Charles Edward Flam, 5782, Trinity, Theodore H.Shapiro, 5175, Côte Saint-Luc, et Douglas Pascal, 6525, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, de Côte Saint-Luc, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de placement, sous le nom de « Cammi Investments Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc 810 chacune et 3,000 actions privilégiées dc 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 800, Carré Victoria, bureau 612, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5644-1970 Canexim Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Sheldon Finkelstein, 5720, boulevard Cavendish, app.308, Côte Saint-Luc, Pinja E.Blitt, 3333 ouest Jean-Talon, app.603, Montréal, et Bernard Gardner, 405, chemin Northcote, Rosemère, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Canexim Corp.», avec un capital total de 840,000, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et 1,000 actions privilégiées de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1117 ouest, rue Sainte-Catherine, bureau 209, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 / 5561-1970 Centre d'accueil pour alcooliques, La Pocatifere inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes en date du 4e jour d'août 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Anctil, opérateur, Philippe Bois, fonctionnaire, Laurette Thiboutot, épouse de Roland Martin, Anne-Marie Verret, épouse de Alfred Lévesque, toutes deux ménagères, Gisèle Laplante, fille majeure, Marcel Létour-neau, tous deux professeurs, Benoit Laplante, aumônier, et Benoît-H.Blanchet, travailleur social, tous de La Pocatière, pour les objets suivants: Le traitement physique et mental des alcooliques, pré-cure et post-cure.La réadaptation des alcooliques et l'entraide aux alcooliques sous toutes ses formes, sous le nom de « Centre d'accueil pour alcooliques, La Pocatière inc.\".cember, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Charles Edward Flam, 5782 Trinity, Theodore II.Shapiro, 5175 Côte St.Luc, and Douglas Pascal, 6525 Côte St.Luc, all three advocates, of Côte Saint-Luc, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Cammi Investments Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at S00 Victoria Square, Suite 612, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5644-1970 Canexim Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Sheldon Finkelstein, 5720 Cavendish Boulevard, Apt.308, Côte Saint-Luc, Pinja E.Blitt, 3333 Jean-Talon Street West, Apt.603, Montreal, and Bernard Gardner, 405 Northcote Road, Roscmème, all three advocates, for the following purposes: To deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Canexim Corp.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 3,000 common shares of 810 each and 1,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at 1117 St.Catherine Street West, Suite 209, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5561-1970 Centre d'accueil pour alcooliques, La Pocatière inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert Anctil, operator, Philippe Bois, civil servant, Laurette Thiboutot, wife of Roland Martin, Anne-Marie Verret, wife of Alfred Lévesque, both .housewives, Gisèle Laplante, spinster of the full age of majority, Marcel Létourneau, both professors, Benoit Laplante, chaplain, and Benolt-H.Blanchet, social worker, all of La Pocatière, for the following purposes: Physical and psychiatric treatment of alcoholics, pre-and post-cure; the readaptation of alcoholics and the promotion of all kinds of aid among alcoholics, under the name of \"Centre d'accueil pour alcooliques, La Pocatière, inc.\". QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 8100,000.Le siège social de la corporation est à La Pocatière, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 3231-1970 Le centre dc formation de Pédicures et de Podiûtrcs inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 24e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Bernard Ranger, 86, Bord du Lac, Pointe Claire, Jean Blain, 298, Jeanne-Petit, Bouchervillc, et Patrick Long, 1425, Jacques Lemaistre, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Dispenser des cours de formation à l'intention dc pédicures et dc podifttres, sous le nom dc « Le centre dc formation dc Pédicures' et dc Podiûtrcs inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5696-1970 Centre dc roulottes Duberger inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Renée Trahan, infirmière, fille majeure, 891, Place Beloeil, app.2, Sainte-Foy, Êmilien Bolduc, garagiste, 1, boulevard Hamel, et Yolande Morisctte, ménagère, épouse de Joseph Mori-sette, 260, Lejeune, ces deux derniers de Québec, poulies objets suivants: Faire le commerce de roulottes de voyage, tentes, tentes-remorques, maisons mobiles, autos-neige, motocyclettes, bicyclettes, automobiles ainsi que tout équipement mobile pouvant être utilisé sur les voies publiques ou privées, sous le nom de « Centre de roulottes Duberger inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,500 actions ordinaires d'une valeur nominale le $10 chacune et en 1,500 actions privilégiées d'une valeur nominale de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5687-1970 1963 The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation may acquire or possess is 8100,000.The head office of the corporation is at La Pocatière, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instilutiotis, Companies and Cooperatives.38854 3231-1970 Le centre de formation de Pédicures et de Podiâtres inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 24th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Bernard Ranger, 86 Bord du Lac, Pointe Claire, Jean Blain, 298 Jeanne-Petit, Boucherville, and Patrick Long, 1425 Jacques Lemaistre, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To give courses for the training of chiropodists and pedicurists, under the name of \"Le centre dc formation de Pédicures et de Podiâtres inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of 81 each and 3,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5696-1970 Centre de roulottes Duberger inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Renée Trahan, nurse, spinster of the full age of majority, 891 Beloeil Place, Apt.2, St.Foy, Êmilien Bolduc, garage-owner, 1 Hamel Boulevard, and Yolande Morisette, housewife, wife of Joseph Morisettc, 260 Lejeune, the latter two of Québec, for the following purposes: To deal in travel trailers, tents, trailer-tents, mobile homes, snowmobiles, motorcycles, bicycles, automobiles as well as all mobile equipment for use on public or private highways, under the name of \"Centre de roulottes Duberger inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 2,500 common shares of a nominal value of $10 each and 1,500 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5687-1970 1964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 Centre d'information des cadres administratifs C.I.C.A.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en date du 4c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Pierre-Louis Trudeau, agent d'affaires, 755, Cardinal, Saint-Laurent, Pierre De-guire, photographe, 1190, Belleville, Laval, et Jacques Charhonneau, publicitaire, 1057, Michel Morcau, Bouchcrville, pour les objets suivants: Établir, diriger, promouvoir, organiser, surveiller et contrôler des expositions, conférences, cours éducatifs, congrès, foires et exhibitions, sous le nom de « Centre d'information des cadres administratifs C.I.C.A.inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 100 actions ordinaires dc S100 chacune et en 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social dc la compagic est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5525-1970 Jos.D.Chabot et fils inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jacques Auger, 35, Salabcrry, Pierre Lcmieux, 56, Fraser, et Paul-Henri Lacroix, 37, St-Omer, tous trois notaires, dc Lévis, pour les objets suivants: Industrie et commerce «lu bois, sous le nom «le « Jos.D.Chabot et fils inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires «l'une valeur nominale de 810 chacune et en 3,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social «le la compagnie est à Saint-Lazare, district judiciaire de Montmagny.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe BoucnARD.38854-o 5517-1970 Châtcauguuy Figure Skating Club Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Garth Rois-ton, ingénieur, 374, rue Frontenac, James Murphy, technicien, 144, Melrose, et Gerald Whalen, analyste, 109, Braik, tous trois de Châteauguay, pour les objets suivants: Établir, entretenir et diriger un club athlétique, sous le nom de « Châteauguay Figure Skating Club Inc.».Centre d'information des cadres administratifs C.I.C.A.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre-Louis Trudeau, business agent, 755 Cardinal, Saint-Laurent, Pierre Dcguire, photographer, 1190 Belleville, Laval, and Jacques Charbonneau, publicist, 1057 Michel Morcau, Bouchcrville, for the following purposes: To establish, direct, promote, organize, oversee anil control exhibitions, lclturcs, educational courses, congresses, fairs and exhibitions, under the name of \"Centre d'information «les cadres administratifs C.I.C.A.inc.\", with a total capital stock of 840,000.divided into 100 common shares of $100 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M inistcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5525-1970 Jos.D.Chabot et fils inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing «latc the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies an«l Cooperatives, incorporating: Jacques Auger, 35 Salaberry, Pierre Lc-mieux, 56 Fraser, ami Paul-Henri Lacroix, 37 St-Omer, all three notaries, of Levis, for the following purposes: The lumber trade, under the name of \"Jos.D.Chabot et fils inc.\", with a total capital slock of 840,000, divided into 1,000 common shares of a nominal value of 810 each and into 3,000 preferred shares of a nominal value of $10 each.The head office of the company is at Sain l-Lazare, judicial district of Montmagny.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5517-1970 Châteauguay Figure Skating Club Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Garth Rolston, engineer, 374 Frontenac Street, James Murphy, teclmician, 144 Melrose, and Gerald Whalen, analyst, 109 Braik, all three of Châteauguay, for the following purposes: To establish, maintain and conduct an athletic club, under the name of \"Châteauguay Figure Skating Club Inc.\". QUEBEC OFFICIAL \"GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le montant auquel est limitée la valeur de la propriété immobilière que la corporation peut acquérir et détenir est $25,000.Le siège social de la corporation est 36, rue Edward, Châteauguay, district judiciaire de Beauharnois.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniuppE Bouchard.3S854 5688-1970 La Cic électrique Menard inc.Menard Electric Co.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 27c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Patrice Ménard, maître-électricien, Jane Ménard, ménagère, épouse dudit Patrice Ménard, tous deux du 110, avenue Irvine, Westmount, et Roger Lupicn, directeur des ventes, 4560, de Lori-micr, Montréal, pour les objets suivants: S'établir entrepreneurs en électricité et faire affaires dans les domaines connexes, sous le nom de « La Cic électrique Ménard inc.\u2014 Ménard Electric Co.Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 465, rue McGill, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-PniuppE Bouchard.38854 5268-1970 Ciné-Parc Bélair inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Georges Rioux, homme d'affaires, 739, Le Payeur, Sainte-Foy, Michèle Roy, 384, Lock-well, et Rita Gagnon, 811, Cardinal-Rouleau, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Québec, pour les objets suivants: Exploiter un ciné-parc, sous le nom de « Ciné-Parc Bélair inc.», avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur nominale.Le siège social de la compagnie est ù Bélair, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 224-1971 Ciné-Parc Vaudrcuil ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jason Ruby, 47, Place Dubois, Dollard-des-Ormeaux, Joanne Doran, 2300, Saint- 1965 The amount to which the value of the immovable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is $25,000.The head office of the corporation is at 36 Edward Street, Châteauguay, judicial district of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5688-1970 La Cic électrique Ménard inc.Ménard Electric Co.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 27th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies arid Cooperatives, incorporating: Patrice Ménard, master electrician, Jane Ménard, homemaker, wife of the said Patrice Ménard, both of 110 Irvine Avenue, Westmount, and Roger Lupien, sales executive, 4560 de Lorimier, Montreal, for the following purposes: To engage in the business of electrical contracting and all related activities, under the name of \"La Cie électrique Ménard inc.\u2014 Ménard Electric Co.Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of a par value of $1 each and 20,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at 465 McGill Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5268-1970 Ciné-Parc Bélair inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Rioux, businessman, 739 Le Payeur, St.Foy, Michèle Roy, 384 Lockwell, and Rita Gagnon, 811 Cardinal-Rouleau, the latter two secretaries, spinsters of the full age of majority of Québec, for the following purposes: To operate a drive-in, under the name of \"Ciné-Parc Bélair inc.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without nominal value.The head office of the company is at Bélair, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 224-1971 Ciné-Parc Vaudrcuil ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jason Ruby, 47 Place Dubois, Dollard-des-Ormeaux, Joanne Doran, 2300 St.Mathew, and Carole I960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, w° 9 Mathieu, et Carole de Francesco, 7148, Hamilton, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, de Montréal, pour les objets suivants: Exploiter des cinémas, des ciné-parcs et autres théâtres ou endroits de divertissement, d'enseignement ou de spectacles, sous le nom de « Ciné-Parc Vaudrcuil ltée », avec un capital total de §65,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de $1 chacune et 60,000 -actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Horion, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5764-1970 de Francesco, 7148 Hamilton, the latter two secretaries, spinsters, of Montreal, for the following purposes: To operate motion picture theatres, drive-in theatres, or other theatres and places of amusement or instruction or entertainment of every kind, under the name of \"Ciné-Parc Vaudreuil ltée\", with a total capital stock of 865,000 divided into 5,000 common shares of 81 each and 60,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at Dorion, judicial district of Montreal.Lb-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 ' 5704-1970 Club de Molo-Ncige Dorion Garden inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: J.-Paul Havington, pompier, Charles Lefebvre, contremaître, Raymond Simard, menuisier, Claude Wermert, mécanicien, tous quatre de rue Archambault, Pierre Laplante, conseiller en main d'oeuvre, 567, Archambault, Gilles Arsenault, comptable, André Béland, 559, Downs, Claude Prono-vost, rue Galt, et Claude Trudcl, 217, Des Loisirs, ces trois derniers professeurs, tous de Dorion, pour les objets suivants: Promouvoir le sport de la moto-neige, sous le nom de « Club de Moto-Neige Dorion Garden inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 820,000.Le siège social de la corporation est à Dorion, district judiciaire de Beauharnois.Lé sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 22-1971 Club de Moto-Neige Dorion Gurdcn inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January.1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: J.-Paul Havington, fireman, Charles Lefebvre, foreman, Raymond Simard, carpenter, Claude Wermert, mechanic, all four of Archambault Street, Pierre Laplante, labour consultant, 567 Archambault, Gilles Arsenault, accountant, André Béland, 559 Downs, Claude Pronovost, Gait Street, and Claude Trudcl, 217 Des Loisirs, the latter three professors, all of Dorion, for the following purposes: To promote snowmobiling, under the name of \"Club de Moto-Neige Dorion Garden inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is 820,000.The head office of the corporation is at Dorion, judicial district, of Beauharnois.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 22-1971 Club de recherches économiques du Québec limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Raymond Boily, 842, avenue Duchesneau, Michel Poulin, 653, avenue Charron, tous deux avocats, de Sainte-Foy, et Michèle Létourneau, secrétaire, épouse de Gaétan Chabot, 4520, 4e avenue est, Charlesbourg, pour les objets suivants: Intéresser les membres aux questions économiques québécoises par des recherches, des conférences et des publications, sous le nom de « Club de recherches économiques du Québec limitée ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 850,000.Club de recherches économiques du Québec limitée Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of January, 1971, have been issued by the Minister ot Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Raymond Boily, 842 Duchesneau Avenue, Michel Poulin, 653 Charron Avenue, both advocates, of St.Foy, and Michèle Létourneau, secretary, wife of Gaétan Chabot, 4520, 4th Avenue East, Charlesbourg, for the following purposes: To interest the members in the economic questions facing Québec through research, conferences and publications, under the name of \"Club de recherches économiques du Québec limitée\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $50,000. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le siege social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 193-1971 Club Lions dc Jolicttc inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Jacques Fa-lardeau, gérant, 120, rue Robert, Normand Roy, directeur du personnel, rue Manscau, tous deux de Joliette, et Maurice Bourassa, gérant des ventes, 151, Ire Avenue, Notre-Dame-des-Prairics, pour les objets suivants: Promouvoir la théorie et la pratique des principes de bon gouvernement et de civisme et prendre un intérêt actif au bien-être civique, social et moral de la communauté, sous le nom de « Club Lions de Joliette inc.».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la'corporation, est de 850,000.Le siège social de la corporation est à Joliette, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 4510-1970 Club social des employés dc la Régie de l'Assurance-Maladic du Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Gabriel Pelletier, 2064, chemin St-Louis, Sillery, Eugène House, 435, 46e Rue ouest, Charlesbourg, Paul-Henri Matte, 2643, chemin Ste-Foy, Serge Métivier, 3040, chemin St-Louis, André Didier, 2752, Bel-Air, Pierre Piché, 2829, chemin St-Louis, tous quatre de Sainte-Foy, Olyve Legendre, 1080, Forget, Sillery, Francine Fournier, 485, St-Amable, Carmen Couture, 400, Champlain, toutes trois filles majeures, Serge LeRouzès, 775, Vimy, tous trois de Québec, et Linda Andrews, épouse de Leopold Jacques, 88, boulevard François-Xavier, Montmorency, tous fonctionnaires, pour les objets suivants: Établir et administrer un club social, sous le nom de < Club social des employés de la Régie de l'Assurancc-Maladie du Québec ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est de 840,000.Le siège social de la corporation est à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-q 194-1971 1967 The head office of the corporation is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 193-1971 Club Lions de Joliette inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital : Jacques Falardeau, manager, 120 Robert Street, Normand Roy, personnel manager, Manseau Street, both of Joliette, and Maurice Bourassa, sales manager, 151, 1st Avenue, Notre-Dame-dcs-Prairies, for the following purposes: To promote the theory and practice of the principles of good government and public-spiritedness and to take an active interest in the civic, social and moral welfare of the community, under the name of \"Club Lions de Joliette inc.\".The amount to which is limited the value of the im-mobable property which the corporation may acquire and possess, is 850,000.The head office of the corporation is at Joliette, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 4510-1970 Club social des employés de la Régie dc l'Assurancc-Maladie du Québec Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital : Gabriel Pelletier, 2064 St.Louis road, Sillery, Eugène Houde, 435, 46th Street West, Charlcsbourg, Paul-Henri Matte, 2643 St.Foy Road, Serge Métivier, 3040 St.Louis road, André Didier, 2752 Bel-Air, Pierre Piché, 2829 St.Louis Road, all four of St.Foy, Olyve Legeridre, 1080 Forget, Sillery, Francine Fournier, 485 St-Amable, Carmen Couture, 400 Champlain, all three spinsters of the full age of majority, Serge LeRouzès, 775 Vimy, all three of Québec, and Linda Andrews, wife of Lépold Jacques, 88 François-Xavier Boulevard, Montmorency, all civil servants, for the following purposes : To set up and administer a social club, under the name of \"Club social des employés de la Régie de l'Assurance-Moladie du Québec\".The amount to which is to be limited the value of the real estate which the corporation may acquire or possess if 840,000.The head office of the corporation is at Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 194-1971 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108- année, n\" 9 Computerized Rental Service (CRS) Inc.Service dc location par ordinateur (CRS) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Giacomo Georgio Sand, 211, avenue Dresden, Mont-Royal, |Bralim L.Campbell, 43, Aldrcd Crescent, Hampstcad, et William D.Schwartz, 7452, Ostell Crescent, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Fournir des services d'administration, dc recherche, de traitement des données et autres services connexes pour développer les ressources des systèmes d'ordinateurs pour les personnes et/ ou les corporations, sous le nom dc « Computerized Reiital Service (CRS) Inc.\u2014 Service dc location par ordinateur (CRS) inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 81 chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 7-1971 Jacques Couvrette inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Pierre Lalandc, avocat, 1, Place Laval, Laval, Denise Valiquette, épouse de Jean-Georges Girard, 1681, Sauvé est, et Ginette Huneault, filie majeure, 7283, Bcrri, ces deux dernières secrétaires, dc Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de transport, sous le nom de « Jacques Couvrette inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et en 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 4434, rue Lanicl, Pierrefonds, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 23-1971 Crossfield Realties Ltd.Les immeubles Crossfield ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, David Katznclson, 145, chemin Radcliffe, Montréal-Ouest, et Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Computerized Rental Service (CRS) Inc.Service de location par ordinateur (CRS) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Giacomo Goorgio Sand, 211 Dresden Avenue, Mount Royal, Brahm L.Campbell, 43 Aldrcd Crescent, Hampstead, and William D.Schwartz, 7452 Ostell Crescent, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To supply management, research, data processing and related services to develop computer systems for persons and or corporations, under the name of \"Computerized Rental Service (CRS) Inc.\u2014 Service de location par ordinateur (CRS) inc.\", with a total capital stock of S10.000, divided into 10,000 common shares of a par value of SI each and 30,000 preferred shares of a par value of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 7-1971 Jacques Couvrette inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating : Pierre Lalandc, advocate, 1 Place Laval, Laval Denise Valiquette, wife of Jean-Georges Girard, 16S1 Sauvé East, and Ginette Huneault, spinster of the full age of majority, 7283 Berri, the latter two secretaries, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as a transport company, under the name of \"Jacques Couvrette inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of 81 each and into 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 4434 Lanicl Street, Pierrefonds, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Mi7iister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 23-1971 Crossfield Realties Ltd.Les immeubles Crossfield liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, David Katznelson, 145 Radcliffe Road, Montreal West, and Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Établir et diriger une compagnie d'immeuble, de construction et dc placement, sous le nom dc « Crossfield Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Crossfield ltée», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 36,000 actions privilégiées de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1, place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiaud.38854 5780-1970 Cutlass Industries Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Donald Fisher, administrateur, Kerry Fisher, secrétaire, épouse dudit Donald Fisher, tous deux du 239, boulevard Dcguire, app.220, Suint-Laurent, John A.Griffiths, commis, 490, boulevard Ualland, app.26, et David C.Griffiths, gérant, 490, boulevard Galland, app.22, ces deux derniers dc Dorval, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes dc produits, articles et marchandises, sous le nom de « Cutlass Industries Ltd.», avec Un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc 300 actions privilégiées dc S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 239, boulevard Dcguire, app.220, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Bouchard.38854 5672-1970 D.C.B.Industries Ltd.Industries D.C.B.ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, constituant eu corporation: Richard J.F.Bowie, 181, avenue Morrison, Lambert Toupin, 194, avenue Melbourne, Bertrand Lacombe, 1780, Dumfries, tous trois de Mont-Royal, C.Stephen Cheaslcy, 341, Berkeley Circle, Dorval, James G.Wright, 3164, Le Boulevard, Montréal, Michael P.Carroll, 254, avenue Metcalfe, West-mount, et Claude Laehance, 30, Place Côte Vertu, Saint-Laurent, tous avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de placement, sous le nom de « D.C.B.Industries Ltd.\u2014 Industries D.C.B.ltée », avec un capital total divisé en 2,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 12,514 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 40-1971 1969 To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Crossfield Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Crossfield ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of SI each and 36,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 1 Place Ville-Marie, suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5780-1970 Cutlass Industries Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Compunies and Cooperatives, incorporating: Donald Fisher, executive, Kerry Fisher, secretary, wife of the said Donald Fisher, both of 239 Dcguire Boulevard, Apt.220, Saint-Laurent, John A.Griffiths, clerk, 490Gulland Boulevard, Apt.26, and David C.Griffiths, manager, 490 Galland Boulevard, Apt.22, the latter two of Dorval, for the folllowing purposes : To manufacture and dcul in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Cutlass Industries Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of S10 each and 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 239 Deguire Boulevard.Apartment 220, Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5672-1970 D.C.B.Industries Ltd.Industries D.C.B.lié.Notice is given that under Purt I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Richard J.F.Bowie, 181 Morrison Avenue, Lambert Toupin, 194 Melbourne Avenue, Bertrand Lacombe, 1780 Dumfries, ull three of Mount Royal, C.Stephen Cheasley, 341 Berkeley Circle, Dorval, James G.Wright, 3164 The Boulevard, Montréal, Michael P.Carroll, 254 Metcalfe Avenue, Wcstmount, and Claude Lachancc, 30 Place Côte Vertu, Saint-Laurent, all advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"D.C.B.Industries Ltd.\u2014 Industries D.C.B.ltée\", with a capital stock divided into 2,000,000 common shares no par value and 12,514 preferred shares of a par value of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 40-1971 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 1970 D.K.Distributors Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: William Sherman, comptable, 2240, rue Décolles, Saint-Laurent, Rcevin Pcarl, 5745, Côte Saint-Luc, Hampstead, et Michel Béland, 2790, Glencoc, Montréal, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Créer, établir, ériger et maintenir une entreprise d'achats et de ventes pour la promotion, la publicité, la distribution ou la mise en marché dc toutes sortes de services ou produits, marchandises, biens mobiliers et objets de commerce de toutes sortes et de toute nature, sous le nom de « D.K.Distributors Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54 5572-1970 Dcpinn Industries Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Max S.Kaufman, 574, Clarcmont, Westmount, Sydney B.Scderoff, 80, Crcstwood, Montréal-Ouest, et Philip Shugar, 6267, MacDonald, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir promoteurs, conseillers et experts en administration, et donner des services d'administration en affaires, sous le nom dc « Dcpina Industries Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 56-1971 Les distributeurs dc produits industriels de Scpt-Ilcs lice Scpt-Ilcs Industrial Products Distributors Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Earl P.Wood, technicien, 360, Marquette, Laurie Leblanc, administrateur d'entreprise, 179, Papineau, et Jean Dionne, avocat, 202, Cartier, tous trois de Scpt-Ilcs, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de quincaillerie, sous le nom de < Les distributeurs de produits industriels de D.K.Distributors Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: William Sherman, accountant, 2240 Dccclles Street, Saint-Laurent, Rccvin Pearl, 5745 Côte St.Luc, Hampstead, and Michel Béland, 2790 Glencoc, Montreal, the latter two advocates, for the following purposes: To create, establish, build up, and maintain a selling or purchasing organization for the promotion, sale advertisement, distribution, or introduction of any and all services or products, merchandise, personal property and subjects of trade or commerce of every kind or nature, under the name of \"D.K.Distributors Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5572-1970 Dcpina Industries Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Max S.Kaufman, 574 Clarcmont, Westmount, Sydney B.Scderoff, 80 Crestwood, Montreal West, and Philip Shugar, 0267 MacDonald, Montreal, nil three advocates, for the following purposes: To act as business promoters, consultants and advisors and to provide business management, under the name of \"Depina Industries Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of S10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 56-1971 Les distributeurs dc produits industriels de Scpt-lles ltée Sept-Ilcs Industrial Products Distributors Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Earl P.Wood, technician, 360 Marquette, Laurie Leblanc, business executive, 179 Papineau, and Jean Dionnc, lawyer, 202 Cartier, all three of Sept-Iles, for the following purposes: To manufacture and deal in hardware, under the name of \"Les distributeurs dc produits industriels de QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February S7, 1971, Vol.103, No.9 1971 Scpt-Ilcs ltée \u2014 Scpt-Ilcs Industrial Products Distributors Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair dc S10 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 360, Noël, Scpt-Ilcs, district judiciaire dc Hautcrive.Ix tout-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 5692-1970 Dollurd Supertest Service Station Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Daniel Kingstone, 4985, Iona, André Larivière, 3101, Edouard-Montpctit, tous deux dc Montréal, et Gilles Poulin, 103, Ashton, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: S'établir garagistes et faire le commerce dc véhicules de transport, voitures et accessoires et pièces de toutes sortes, sous le nom de « Dollard Supertest Service Station Ltd.», avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Lasalle, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5377-1970 Domaine du hois dc Montréal (1970) ltée Domaine du hois of Montreal (1970) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: David Katznclson, 145, chemin Itadcliffc, Ralph Lippcr, 1550, avenue McGregor, tous deux dc Montréal, et Robert Litvack, 590, avenue Stanstcad, Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble, dc construction et de placement, sous le nom de « Domaine du bois de Montréal (1970) ltée \u2014 Domaine du bois of Montreal (1970) Ltd.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 4,000 actions ordinaires de SI chacune et 36,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est au 1, Place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5782-1970 Dundee Investments Inc.Les investissements Dundee inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première Scpt-Ilcs ltée \u2014 Scpt-Ilcs Industrial Products Distributors Ltd.\", with a total capital stock of 540,000, divided into 2,000 common shares of the par value of S10 each and 2,000 preferred shares of the par value of $10 each.The head office of the company is at 360 Noël, Scpt-Ilcs, judicial district of Hautcrive.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5692-1970 Dollard Supcrtcst Service Station Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Daniel Kingstonc, 4985 Iona, André Larivière, 3101 Ëdouard-Montpctit, both of Montreal, and Gilles Poulin, 103 Ashton, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in conveyances and vehicles and accessories and parts thereof of every kind, under the name of \"Dol'ard Supcrtcst Service Station Ltd.\", with a capital stock divided into 40,000 shares without par value.The head office of the company is at Lasalle, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 .5377-1970 Domaine du hois de Montréal (1970) ltée Domaine du bois of Montreal (1970) Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Kal/.nclson, 145 Radcliffe Road, Ralph Lipper, 1550 McGregor Avenue, both of Montreal, and Robert Litvack, 590 Slanstead Avenue, Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Domaine du bois de Montréal (1970) ltée \u2014 Domaine du bois of Montreal (1970) Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of SI each and 36,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at 1 Place Ville-Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5782-1970 Dundee Investments Inc.Les investissements Dundee inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108' année, n° 9 1972 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, David Katznclson, 145, chemin Radcliffe, tous deux de Montréal, et Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de placement, sous le nom de « Dundee Investments Inc.\u2014 Les investissements Dundee inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est au 1, Place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5781-1970 Dus \u2014 Can inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du ISe jour de décembre 1970, constituant en corporation: Jacques Soucy, notaire, 1995, Ire Avenue, Gisèle Miller, épouse de Sarto Poulin, 1251, 3c Avenue, et Denise Caron, épouse de Paul Nolet, 275, des Lilas ouest, ces deux dernières secrétaires, tous trois de Québec, pour les objets suivants: Exercer le commerce de fournisseur de matériaux, sous le nom de « Dus-Can inc.», avec un capital total de 850,000, divisé en 5,000 actions ordinaires de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 6985, 7e Avenue est, Charlesbourg, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5103-1970 Dynco Management Corp.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Michael Worsoff, Steven Kleiner, tous deux avocats, du 7925, chemin Kingsley, Côte Saint-Luc, et Beyerley Nowell, secrétaire, épouse de Peter Nowell, 482, rue Vcrchères, Greenfield Park, pour les objets suivants: S'établir conseillers en administration, conseillers et experts industriels et conseils dans l'exploitation de toutes sortes d'entreprises, sous le nom de « Dynco Management Corp.», avec un capital total de 840,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 30,000 actions privilégiées de $1 chacune.December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ralph Lippcr, 1550 McGregor Avenue, David Katznclson,-145 Radcliffe Road, both of Montreal, and Robert Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Dundee Investments Inc.\u2014 Les investissements Dundee inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of the par value of $1 each and 36,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 1 Place Ville-Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5781-1970 Dus - Can inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Soucy, notary, 1995, 1st Avenue, Gisèle Miller, wife of Sarto Poulin, 1251, 3rd Avenue, and Denise Caron, wife of Paul Nolet, 275 des Lilas West, the latter two secretaries, all three of Québec, for the following purposes: To deal in the material supplying business, under the name of \"Dus - Can inc.\", with a total capital stock of $50,000, divided into 5,000 common shares of $10 each.The head office of the company is at 6985, 7th Avenue East, Charlcsbourg, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5103-1970 Dynco Management Corp.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michael Worsoff, Steven Kleiner, both advocates, of 7925 Kingsley Road, Côte Saint-Luc, and Beverley Nowell, secretary, wife of Peter Nowell, 482 Verchères Street, Greenfield Park, for the following purposes: To carry on business as management consultants, industrial consultants and advisors and consultants in the operation of all kinds of businesses, under the name of \"Dynco Management Corp.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 30,000 preferred shares of $1 each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5732-1970 E.S.P.Electronics Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de septembre 1970, constituant en corporation: James Gougli, administrateur, Case postale 152, Clarenccvillc, Seymour Macblovitch avocat, 3495, Mountain, Montréal, et Madeleine La-mothe, secrétaire, épouse de Nelson Jackson, 155, DeGuire, Saint-Laurent, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc produits électroniques et électriques, machinerie et équipement de toute nature et de toute description, sous le nom de « E.S.P.Electronics Ltd.», avec un capital total de 340,000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc SI chacune et 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 3554-1970 Éditions Jeunesse inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Gontran Trotticr, 7391, De Bcl-froy, Montreal, Réal D'Anjou, 1432, dc Villars, Sillery, tous deux éditeurs, et Gilles Canucl, comptable, 1904, Godin, Laflèchc, pour les objets suivants: Faire affaires comme éditeurs, enseignants, libraires, imprimeurs, graveurs, relieurs, entrepreneurs de messageries et distributeurs de livres, sous le nom de « Éditions Jeunesse inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires dc SI chacune et en 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 342, Terrasse St-Denis, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5380-1970 1177 Realties Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Stephen Ostrow, administrateur, 316, 71st Street West, New York, Carmen Russo, gérant, 695 St.George Avenue, Woodbridge, et Helen Herschorn, comptable, épouse divorcée de 1973 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARp, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-e 5732-1970 E.S.P.Electronics Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of September, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: James Gough, executive, P.O.Box 152, Clarenccvillc, Seymour Muchlovitch, advocate, 3495 Mountain, Montreal, and Madeleine Lamothe, secretary, wife of Nelson Jackson, 155 DcGuirc, Saint-Laurent, for the following purposes: To manufacture and deal in electronic and electrical products, machinery and equipment, of every nature and description, under the name of \"E.S.P.Electronics Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 3554-1970 Editions Jeunesse inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, Icttcr,s patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gontran Trotticr, 7391 Dc Belfroy, Montreal, Real D'Anjou, 1432 de Villars, Sillery, both publishers, and Gilles Canuel, accountant, 1904 Godin, Laflèchc, for the following purposes: To carry on business as publishers, teachers, booksellers, printers, engravers, bookbinders, shipping service contractors and book distributors, under the name of \"Éditions Jeunesse inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of SI each and into 300 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 342 Terrasse St-Denis, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 53S0-1970 1177 Realties Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Stephen Ostrow, executive, 316, 71st Street West, New York, Carmen Russo, manager, 695 St.George Avenue, Woodbridge, and Helen Herschorn, accountant, wife divorced of Joseph 1974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Joseph Herschorn, 97,11 Horace Harding Expressway, Corona, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et dc construction, sous le nom de « 1177 Realties Inc.», avec un capital divisé en 40,000 actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 5494-1970 Elite Warehousing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Gordon McQuilIcn, entrepositaire, 359, Latour, Richard McQuilIcn, secrétaire, 201, Saint-Henri, et André Gagnon, notaire, 542, Raymond, tous trois de Saint-Jean, |H»ur les objets suivants: Établir et diriger une entreprise d'entreposage cl dc dépôt, sous le nom dc « Elite Warehousing Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 359, rue Latour, Saint-Jean, district judiciaire d'Ibcrville.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 106-1971 Emco Ment Packers Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Morton Bell, 701, Bertrand Circle, Saint-Laurent, Stanley Cytrynbaum, 234, Sheraton Drive, Montréal-Ouest, tous deux avocats, et Allan Wolinsky, étudiant, 5950, Côte des Neiges, app.334, Montréal, pour les objets suivants: Faire le commerce dc viandes, bestiaux, moutons, porcs et de tous les produits alimentaires dc façon générale, ainsi que dc peaux, fourrures, cuirs, suif, graisses, engrais, sabots, et autres produits de l'animal, et de produits laitiers, dc la ferme et du jardin, sous le nom de « Emco Meat Packers Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 9031, avenue du Parc, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Lb-Philippe Bouchard.38854 5579-1970 Enra Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres Herschorn, 97, 11 Horace Harding Expressway, Corona, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"1177 Realties Inc.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5494-1970 Elite Warehousing Inc.Notice is given that under Prat I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Gordon McQuilIcn, warehouseman, 359 Latour, Richard McQuilIcn, secretary, 201 St.Henri, and André Gagnon, notary, 542 Raymond, all three of Saint-Jean, for the following purposes: To carry on a warehouse and storage business, under the name of \"Elite Warehousing Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at 359 Latour Street, St.John's, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 106-1971 Emco Meat Packers Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Morton Bell, 701 Bertrand Circle, Saint-Laurent, Stanley Cytrynbaum, 234 Sheraton Drive, Montreal West, both advocates, and Allan Wolinsky, student, 5950 Côte des Neiges, Apt.334, Montreal, for the following purposes: To deal in meat, cattle, sheep, hogs and all food produce generally and skins, hides, furs, leather, tallow, fat, fertilizers, hoofs, and other animal products and dairy, farm and garden produce of all kinds, under the name of \"Emco Meat Packers Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 9031 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5579-1970 Eura Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 1975 patentes, en date du 22c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Irving Halperin, 5609, chemin dc la Reine Marie, Hampstead, Daniel Morris, 6165, avenue Notre-Damc-de-Grûcc, tous deux avocats, Georgette Lavoie, 2869, Granby, et Bridget Harte, 4600, chemin dc la Reine Marie, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, les trois derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans le recrutement et l'entraînement dc personnel dc vente, dans toutes les spécialités du recrutement et dc l'entraînement, sous le nom dc « Enra Corporation », avec un capital total dc 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 2,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouciiahd.38854 5667-1970 Etcheverry Enterprises Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de janvier 1971, constituant en cor|K>ration : Ross Hutchings, contrôleur, 426, rue Monmouth, Mont-Royal, Yves L'Anglais, 4257, Jean-Brillant, Montréal, et Charles E.Flam, 5782, avenue Trinity, Côte Saint-Luc, ces deux derniers avocats, pour les objets suivants: Fournir des services d'administration, du contrôle, dc consultation et autres services à toutes compagnies, corporations, entreprises, personnes ou établissements, sous le nom de « Ètcheverry Enterprises Inc.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,900 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 87-1971 Express Tours Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en'vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Antoine Boulos, 4528, Oxford, Montréal, Gil Nachou, 175, Dcguire, tous deux agents dc voyage, et Suzanne Danscreau, secrétaire, épouse dc Claude Chavarie, 292, Deguirc, ces deux derniers de Saint-Laurent, pour les objets suivants: Acheter, acquérir et louer des vaisseaux, avions et autres moyens de transport publics ou privés, afin de faire le transport de voyageurs, dc colis par exprès et fret dans toutes les parties du monde, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, s'établir agence de voyage, sous le nom dc « Express Tours Limited », avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordi- Financial Institutions, Companies and Coopératives, incorporating: Irving Halperin, 5609 Queen Mary Road, Hampstead, Daniel Morris, 6165 Notrc-Damc-de-Grûce Avenue, both advocates, Georgette Lavoie, 2869 Granby, and Bridget Hartc, 4600 Queen Mary Road, the latter two secretaries, spinster of the full age of majority, the latter three of Montreal, for the following purposes: To carry on in all of their respective branches the business of rccruting and training sales personnel, under the name of \"Enra Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of SI each and 2,000 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies arid Cooperatives.38854-0 5667-1970 Etcheverry Enterprises Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ross Hutchings, comptroller, 426 Monmouth Street, Mount Royal, Yves L'Anglais, 4257 Jean-Brillant, Montreal, and Charles E.Flam, 5782 Trinity Avenue, Côte Saint-Luc, the latter two advocates, for the following purposes: To render managerial, supervisory, consultant or other services to any other company, corporation, firm, persons, or business, under the name of \"Etcheverry Enterprises Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 81 each and 3,900 preferred shares of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 87-1971 Express Tours Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Antoine Boulos, 4528 Oxford, Montreal, Gil Nachou, 175 Deguire, both travel agents, and Suzanne Dansereau, secretary, wife of Claude Chavarie, 292 Deguirc, the latter two of Saint-Laurent, for the following purposes: To purchase, acquire and lease vessels, aircrafts or other conveyances, public or private, for the purpose of transporting passengers, express and freight to any part of the world, and without limiting the generality of the foregoing, to engage in and carry on the business of operating a general travel agency, under the name of \"Express Tours Limited\", with a total capital stock 1976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108' année, n\" 9 noires de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 1500, rue Stanley, bureau 200, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5021-1970 Fnirhall Realties Ltd.Les immeubles Fuirliull ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Robert Litvack, 590, Stanstead, Mont-Royal, David Katznclson, 145, Radcliffe, Montréal-Ouest, et Ralph Lippcr, 1550, avenue McGregor, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compugnic d'immeuble, dc construction et dc placement, sous le nom dc « Fuirhall Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Fuirhall ltée», avec un capital total dc $40,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur nu pair dc $1 chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune Le siège social dc la compagnie est 1, Place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5620-1970 Febarm inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première portie dc la Loi des compagnies, il n accordé des lettres patentes, en date du 5c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Fernnnd Bélanger, technicien, 502, Ste-Anne, Marcel Bélanger, cultivateur, route rurale No 3, et René Bélanger, machiniste, 377, Main est, tous trois de Coaticook, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc machineries, instruments, équipements agricoles et industrielles et autres accessoires connexes, sous le nom dc « Febarm inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Coaticook, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5588-1970 Les Fc*es Basques de Trois-Pistoles inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Robert Lévesque, of S40.000, divided into 1,000 common shares of $10 each and 3,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1500 Stanley Street, Room 200, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5021-1970 I a i 111al 1 Realties Ltd.Les immeubles Fairhall liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert Litvack, 590 Stanstead, Mount Royal, David Katznclson, 145 Radcliffe, Montreal West, and Ralph Lippcr, 1550 McGregor Avenue, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Fairhall Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Fairhall ltée\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of the par value of SI each and 36,000 preferred shares of the par value of SI each.The head office of the company is at 1 Place Ville-Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5620-1970 Febarm inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 5th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Fernnnd Bélanger, technician, 502 Ste-Anne, Marcel Bélanger, farmer.Rural Route No.3, and René Bélanger, machinist, 377 Main East, all three of Coaticook, for the following purposes: To manufacture and deal in machinery, instruments, farm and industrial equipment and other accessories related therewith, under the name of \"Febarm inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at Coaticook, judicial district of Saint-François.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5588-1970 Les Fees Basques de Trois-Pistoles inc.Notice is given that under Part HI of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 276, Martin, Armandc Lcblond, fille majeure, 514, Vezina, tous deux comptables, et Yolande D'Autcuil, ménagère, épouse de Philippe D'Autcuil, 275, Richard, tous trois de Trois-Pistolcs, pour les objets suivants: Administrer un club sportif de majorettes cl promouvoir en particulier la gymnastique, les exercices dc groupe et dc parade, la musique de concert et dc parade, sous le nom dc « Les Fées Basques de Trois-Pistolcs inc.>.Le montant auquel est limitée lu valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, cstdeS25,000.Le siège social dc la corporation est à Trois-Pistoles, district judiciaire de Kamouraska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 2814-1970 Cala Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour dc décembre 1970, constituant en corporation : Stanley L.Cytrynbaum, 95, Rox-ton Crescent, Montréal-Ouest, Samuel Wex, 27, Holt-ham Road, Hampstead, tous deux avocats, Erica Hume, épouse dc Jolin B.Hume, 1210B, Havre des Iles, Laval, et Pierrette Gougcon, épouse de François-Michel Gagnon, 5195, avenue Coolbrook, Montréal, ces deux dernières secrétaires, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom dc « Gala Construction Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,900 actions privilégiées d'une valeur au pair dc $10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 1212, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5590-1970 Gestion François Signori inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc janvier 1971, constituant en corporation: François Signori, commerçant, Ray-monde Bernier, ménagère, épouse dudit François Signori, tous deux de 866, Charles Guimond, Bouchcrville, et Jean Provost, comptable agréé, 725, Davaar, Outremont, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie de placement, de portefeuille et de gestion, sous le nom de « Gestion François Signori inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 60 actions ordinaires dc $1 chacune, 3,976 actions privilégiées classe * A » de $10 chacune et en 180 actions privilégiées classe « B » de $1 chacune.1977 Lévesque, 276 Martin, Armande Leblond, spinster of the full age of majority, 514 Vézina, both accountants, and Yolande D'Autcuil, housewife, wife of Philippe D'Autcuil, 275 Richard, all three of Trois-Pistoles, for the following purposes: To manage a sports club for majorettes and to promote gymnastics, group and marching exercises, concert and marching music, under the name of \"Les Fées Basques de Trois-Pistqles inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $25,000.The head office of the corporaton is at Trois-Pistoles, judicial district of Kamouraska.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 2814-1970 Gala Construction Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Stanley L.Cytrynbaum, 95 Roxton Crescent, Montreal West, Samuel Wcx, 27 Holtham Road, Hampstead, both advocates, Erica Hume, wife of John B.Hume, 1210B Havre des Iles, Laval, and Pierrette Gougcon, wife of François-Michel Gagnon, 5195 Cool-brook Avenue, Montreal, the latter two secretaries, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"Gala Construction Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of $1 each and 3,900 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 1212 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5590-1970 Gestion François Signori inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: François Signori, trader, _ Raymonde Bernier, housewife, wife of said François Signori, both of 866 Charles Guimond, Bouchcrville, and Jean Provost, chartered accountant, 725 Davaar, Outremont, for the following purposes: To carry on business as an investment, holding and management company, under the name of \"Gestion François Signori inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 60 common shares of $1 each, 3,976 class \"A\" preferred shares of $10 each and into 180 class \"B\" preferred shares of $1 each. 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Le siège social de la compagnie est 866, rue Charles Guimond, Bouchcrville, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 145-1971 I^c groupe Baroque de Montréal Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Stephen Kondaks, 2540, Noël, Saint-Laurent, Taras Gabora, Gaelync Gabora, épouse dudit Taras Gabora, tous deux du 4018, Marlowe, Gaston Germain, Andrée Germain, épouse dudit Gaston Germain, tous deux du 1010, Chcrricr, Mireille Lugaeé, épouse de Bernard Lagacé, 3783, Northcliffc, et Claire Segal, fille majeure, 3600, Ridgewood, app.205, ces six derniers de Montréal, tous les sept musiciens, pour les objets suivants: Encourager les entreprises artistiques et musicales, sous le nom de « Le groupe Baroque de Montréal ».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est dc S100.000.Le siège social dc la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5589-1970 Haute coiffure Attilio inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Arthur .1.Marcovitch, 58S7, Centennial, Lawrence Glazer, 5753, Wcsthiinster, tous deux avocats, Meta Csirinyi, fille majeure, 6940, Wiseman, et Jean-M.Guy, 1117, Saint-Mathieu, ces deux dernières secrétaires, tous les quatre de Montréal, pour les objets suivants: Établir et diriger un salon de coiffure et dc beauté pour dames, fournissant des services de manucures, pédicures, de traitements du visage et autres, sous le nom de « Haute coiffure Attilio inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5424-1970 l.J.Contracting Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première The head office of the company is at 866 Charles Guimond Street, Bouchcrville, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M initier of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o .145-1971 Le groupe Baroque de Montréal Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation wi thou t share capital : Stephen Kondaks, 2540 Noël, Saint-Laurent, Taras Gabora.Gaclync Gabora, wife of the said Taras Gabora, both of 4018 Marlowe, Gaston Germain, Andrée Germain, wife of the said Gaston Germain, both of 1010 Chcrricr, Mireille Lagacé, wife of Bernard Lagacé, 3783 North-cliffe, and Claire Segal, fille majeure, 3600 Ridgewood, Apt.205, the latter six of Montreal, all seven musicians, for the following purposes: To promote artistic and musical undertakings, under the name of \"Le groupe Baroque de Montréal\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold or own, is to be limited to $100,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minisler of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5589-1970 Haute coiffure Attilio inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Arthur.!.Marcovitch, 5887 Centennial, Lawrence Glazer, 4753 Westminster, both advocates, Meta Csirinyi, spinster, 6940 Wiseman, and Jean-M.Guy, 1117 St.Matthew, the latter two secretaries, all four of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of a Ladies Hair Stylists and Beauty Salon, including manicures, pedicures, facials and to deal in such services as may be related thereto, under the name of \"Haute coiffure Attilio inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of SI each and 30,000 preferred shares of SI each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.38854-o 5424-1970 l.J.Contracting Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of Decern- QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date 7e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Abel Selick, 1605, chemin Norway, Mont-Royal, Martin (ïross, 190, Nethcrwood Crescent, et Harold Dizgun, 57, Aldred Crescent, ces deux derniers dc Hampstead, tous trois avocats, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc vêtements dc toutes sortes pour hommes et pour dames, sous le nom de « I.J.Contracting Corporation », avec un capital total dc 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc SI chacune et 20,000 actions privilégiées dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est 9600, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5402-1970 Impression D.B.M.inc.D.B.M.Printing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Pierre Métivier, dessinateur, 1480, Longucuil, Fcrnand Blouin, imprimeur, 619, Napoléon, tous deux de Québec, et Jean-Pierre Dutil, représentant, route nationale 2, Saint-Étienne-de-Bçauinont, pour les objets suivants: Exercer le commerce de la production de documents, images, dessins, photographies dc toutes sortes par tous modes d'impression, sous le nom de « Impression D.B.M.inc.\u2014 D.B.M.Printing Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune et en 200 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 1281, boulevard Charest ouest, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5684-1970 Industries Playcat inc.Playcat Industries Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Jacques Vaillancourt, 107, Picardie, Saint-Lambert, Gilles Bertrand, 147, avenue Dunrac, Mont-Royal, et Jean Guy, 5400, de Louisbourg, Montréal, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer et faire le commerce de véhicules toute saison, d'automobiles et de véhicules automobiles de toutes sortes, sous le nom de « Industries Playcat inc.\u2014 Playcat Industries Inc.», avec un capital total de S100.000, divisé en 100,000 actions ordinaires de SI chacune.1979 ber, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Abel Selick, 1605 Norway Road, Mount Royal, Martin Gross, 190 Nethcrwood Crescent, and Harold Dizgun, 57 Aldrcd Crescent, the latter two of Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in women's and men's clothing of every kind, under the name of \"I.J.Contracting Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of 81 each and 20,000 preferred shares of 81 each.The head office of the company is at 9600 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Finuncial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5402-1970 Impression D.B.M.inc.D.B.M.Printing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre Métivier, draftsman, 1480 Longueuil, Fernaud Blouin, printer, 619 Napoléon, both of Québec, and Jean-Pierre Dutil, representative, National Route 2, Saint-Étienne-de-Beoumont, for the following purposes : To produce documents, pictures, drawings, photographs of all kinds by all printing niethods, under the name of \"Impression D.B.M.inc.\u2014 D.B.M.Printing Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 200 common shares of 8100 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 1281 Charest Boulevard West, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5684-1970 Industries Playcat inc.Playcat Industries Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jacques Vaillancourt, 107 Picardie, Saint-Lambert, Gilles Bertrand, 147 Dunrae Avenue, Mount Royal, and Jean Guy, 5400 de Louisbourg, Montreal, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in motor vehicles for all seasons, automobiles and motor vehicles of all kinds, under the name of \"Industries Playcat inc.\u2014 Playcat Industries Inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 100,000 common shares of $1 each. 1980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 Le siège social de la compagnie est à Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5419-1970 Ingham Insurance Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour d'août 1970, constituant en corporation: John M.McDougall, avocat, 226, avenue Fairfield, James Ingham, courtier en assurances, et Jean Ingham, ménagère, épouse dudit James Ingham, ces deux derniers du 254, avenue Fairfield, tous trois de Rosemère, pour les objets suivants: S'établir agents et courtiers en assurances, sous le nom de « Ingham Insurance Inc.», avec un capital total dc S50.000, divisé en 100 actions ordinaires de $100 chacune et 400 actions privilégiées de $100 chacune._Le_ siège social de la compagnie est à Rosemère, district judiciaire de Terrebonne.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 3638-1970 Les installât ions R.G.J.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de janvier 1971, constituant en corporation: Roger Parenteau, Jacques Parenteau, tous deux menuisiers, de 170, des Peupliers, et Gilles Bélisle, comptable, 172, avenue des Peupliers, tous trois de Drummondville, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de meubles et nouveautés de toutes sortes, sous le nom de « Les installations R.G.J.inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 2,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est 832, rue Delage, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 138-1971 Intercontinental Textiles Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Marcel Dobai, administrateur, 16 Post Gasse, Vienna 1, Autriche, Lucille Matte, secrétaire, fille majeure, 7094, 14e Avenue, et Tamas Virag, vendeur, 397 ouest, boulevard Saint-Joseph, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: La confection, l'achat et la vente de marchandises de toutes les catégories et de toutes descriptions, et particu- The head office of the company is at Drummondville, judicial district of Drummond.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5419-1970 Ingham Insurance Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of August, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: John M.McDougall, advocate, 226 Fairfield Avenue, James Ingham, insurance broker, and Jean Ingham, housewife, wife of the said James Ingham, the latter two of 254 Fairfield Avenue, all three of Rosemère, for the following purposes: To carry on business as agents ami insurance brokers, under the name of \"Ingham Insurance Inc.\", with a total capital slock of $50,000, divided into 100 common shares of $100 each and 400 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Rosemère, judicial district of Terrebonne.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 3638-1970 Les installations R.G.J.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Parenteau, Jacques Parenteau, both carpenters of 170 des Peupliers, and Gilles Bélisle, accountant, 172 des Peupliers Avenue, all three of Drummondville, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Les installations R.G.J.inc.\", with a total capital stock of S40,000.divided into 2,000 common shares of $10 each and into 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 832 Delagc Street, St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 138-1971 Intercontinental Textiles Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Dobai, executive, 16 Post Gasse, Vienna 1, Austria, Lucille Matte, secretary, fille majeure, 7094, 14th Avenue, and Tamas Virag, salesman, 397 St.Joseph Boulevard West, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture, buy and sell merchandise of every class and description, and in particular clothing and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 lièrcmcnt, de vêtements et accessoires vestimentaires de toutes sortes, sous le nom dc * Intercontinental Textiles Ltd.», avec un capital total de S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 3,000 actions privilégiées de S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 210 ouest, rue Saint-Jacques, bureau 800, Montréal, district judiciaire dc Montréal./rf! sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 4972-1970 J.& G.Fashions Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Georges Franc, 7627, Broadway, Lasalle, John Oyama, 7959, de l'Épéc, et Nobuo Yamamoto, 8583, Stuart, ces deux derniers de Montréal, tous trois hommes d'affaires, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de tissus et produits de tissus faits en tout ou en partie de laine, coton, rayonne, nylon ou autre fibre, naturelle ou synthétique, ou toute combinaison dc ces produits, sous le nom dc « J.& G.Fashions Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires de SI 0 chacune et 300 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 5505, rue Iberville, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phii.ippe Bouchard.38854 5333-1970 J.P.S.Electronics Inc.Électronique J.P.S.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Ix>i des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Yoinc Goldstein, 6505, Côte Saint-Luc, Robert Lefcort, 5400, Prince of Wales, tous deux de Montréal, et Leonard W.Flanz, 5750, Trinity, Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie dc réparations en électricité et en électronique, sous le nom de « J.P.S.Electronics Inc.\u2014 Électronique J.P.S.inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 81 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5520-1970 1981 wearing apparel of every kind, under the name of \"Intercontinental Textiles Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 210 St.James Street West, Suite 800, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 4972-1970 J.& G.Fashions Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Georges Franc, 7627 Broadway, Lasalle, John Oyama, 7959 de l'Épée, and Nobuo Yamamoto, 8583 Stuart, the latter two of Montreal, all three businessmen, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of fabrics and fabric products, mude in whole or in part of wool, cotton, rayon, nylon, or any other fibre, natural or synthetic or of a combination thereof, under the name of \"J.& G.Fashions Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 300 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 5505 Iberville Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies arid Cooperatives.38854-o 5333-1970 J.P.S.Electronics Inc.Electronique J.P.S.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yoinc Goldstein, 6505 Côte St.Luc, Robert Lefcort, 5400 Prince of Wales, both of Montreal, and Leonard W.Flanz, 5750 Trinity, Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on the business of an electrical and electronics repair company, under the name of \"J.P.S.Electronics Inc.\u2014 Électronique J.P.S.inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 10,000 common shares of the par value of 81 each and 30,000 preferred shares of the par value of 81 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5520-1970 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 Les jardiniers Kxpo ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour de janvier 1971, consti-tant en corporation: l'ietro Miclietti, contremaître.Maria Mancini, ménagère, épouse dudit l'ietro Miclietti, tous deux dc 1759, Montgomery, Luflèclie, et Marcel Brousseau, vendeur, 0645, Papineau, Brossard, pour les objets suivants: Faire affaires comme fleuristes, pépiniéristes et cultivateurs de graines, sous le nom de « Les jardiniers Expo liée », avec un cupital total dc S40.000, divisé en 400 actions ordinaires de S100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 6645, rue Papineau, Brossard, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 243-1971 K.& B.Discount Stores Inc.Magasins d'escompte K.& B.inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Karop Rahill, vendeur, Barbara Redmond, caissère, épouse dudit Karop Rahill, et Viola Shipley, ménagère, épouse dc Edmond Redmond, tous trois du 583, 1ère Rue, Iberville, pour les objets suivants: Acheter, vendre, distribuer, importer et exporter «les marchandises de tous genres, sous le nom de * K.& B.Discount Stores Inc.\u2014 Magasins d'escompte K.& B.inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 1,000 actions ordinaires de S10 chacune et 300 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est 246, rue Richelieu, Saint-Jean, district judiciaire d'Ibcrville.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 86-1971 K.R.Mechanical Contracting Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Klaus J.Roesslcr, 91, rue Collier, Barrie, Alex Beaulicu, 3895, rue Hochelaga, app.3, tous deux monteurs d'appareils de chauffage, et Gertrude Twymenn, professeur, fille majeure, 4525, avenue Roscmont, app.25, ces deux derniers dc Montréal, pour les objets suivants: S'établir entrepreneurs en plomberie, chauffage, réfrigération et électricité, sous le nom de « K.R.Mechanical Contracting Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires d'une valeur au pair Les jardiniers Expo ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters putcnt, bearing date the 18th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pictro Michetti, foreman, Marta Mancini, housewife, wife of said Pietro Michetti, both of 1759 Montgomery, Laflèchc, and Marcel Brousseau, salesman, 6645 Papineau, Brossard, for the following purposes: To carry on business as florists, nurserymen and grain growers, under the name of \"Les jardiniers Expo liée\", with a total capital slock of S40.000, divided into 400 common shares of 8100 each.The head office of the company is at G045 Papineau Street, Brossard, judicial district of Montreal.Ls-Phiijppe Bouchard, Deputy Mi/iister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 243-1971 K.& B.Discount Stores Inc.Magasins d'escompte K.& B.inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Karop Rahill, salesman, Barbara Redmond, cashier, wife of the said Karop Rahill, and Viola Shipley, housewife, wife of Edmond Redmond, nil three of 583, 1st Street, Iberville, for the following purposes: To carry on the business of buying and selling, distributing, importing and exporting merchandise of every type, under the name of \"K.& B.Discount Stores Inc.\u2014 Magasins d'escompte K.& B.inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 300 preferred shares of SI 00 each.The head office of the company is at 246 Richelieu Street, St.John's, judicial district of Iberville.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 86-1971 K.R.Mechanical Contracting Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Klaus J.Roessler, 91 Collier Street, Barrie, Alex Beaulicu, 3895 Hochelaga Street, Apt.3, both steamfitters, and Gertrude Twymenn, teacher, spinster, 4525 Rosemount Avenue, Apt.25, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as plumbing, heating, refrigeration and electrical contractors, under the name of \"K.R.Mechanical Contracting Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 dc $1 chacune et 20,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 81 chacune.Le siège social de la compagnie est 58, rue Angèle, Brossard, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.' 38854 5760-1970 Kin il k i li\\ House Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21c jour dc décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Elsie Bonne-ville, ménagère, épouse de Roger Bonneville, 10132, Belleville, Montréal-Nord, Thérèse Lemay, secrétaire, épouse de William John Durham, 5010, Barclay, app.7, Paul Kearney, gérant de bureau, 3463, Sainte-Famille, Pierre-R.Trépanicr, commis au traffic, 3652, Sainte-Famille, et Howard liai I, am, ingénieur chimiste, 3787, Côte des Neiges, ces quatre derniers de Montréal, pour les objets suivants: Encourager, créer, promouvoir et protéger le développement, l'amélioration et les intérêts de ses membres relativement à leur abstinence des boissons alcooliques, sous le nom dc « Kimbcrley House Inc.*.Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que pcut*|K>sséder ou détenir la corporation est île S100.000.Le siège social dc la corporation est au 3652, Sainte-Famille, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopérai ires, Ls-Philippe Bouchard.38854 5136-1970 1983 shares of the par value of $1 each and 20,000 preferred shares of the par value of 81 each.The head office of the company is at 58 Angèle Street, Brossard, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5760-1970 Kimbcrley House Inc.Notice is hereby given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Elsie Bonneville, housewife, wife of Roger Bonneville, 10132 Belleville, Montreal North, Thérèse Lemay, secretary, wife of William John Durham, 5010 Barclay, Apt.7, Paul Kearney, office manager, 3463 Stc-Famille, Pierrc-R.Trépanicr, traffic clerk, 3652 Ste-Famille, and Howard Bart rain, chemical engineer, 3787 Côte des Neiges, the latter four of Montreal, for the following purposes: To encourage, create, foster, promote and procure the development, improvement and interest of its members in respect of their abstinence from alcoholic beverages, under the name of \"Kimbcrley House Inc.\".The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may hold or possess, is to be limited, is S100.000.The head office of the corporation is at 3652 Stc-Fomillc, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minislcr of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5136-1970 Kolormats Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 26e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: David Gregory, 218, avenue Morrison, Mont-Royal, Michael Rusko, 1390 ouest, avenue des Pins, tous deux avocats, et Frank Cuk, commis, 4640, rue Barclay, app.6, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de revêtement de planchers de toutes sortes, sous le nom de « Kolormats Inc.», avec un capital divisé en 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc 81 chacune.Le siège social de la compagnie est au 399, avenue Clarke, Westmount, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5697-1970 Kolormats Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 26th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: David Gregory, 218 Morrison Avenue, Mount Royal, Michael Rusko, 1390 Pine Avenue West, both advocates, and Frank Cuk, clerk, 4640 Barclay Street, Apt.6, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in floor coverings of all kinds, under the name of \"Kolormats Inc.\", with a capita! stock divided into 10,000 common shares without par value and 30,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 399 Clarke Avenue, Westmount, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5697-1970 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103- année, n° 9 Korba Pizzeria Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc décembre 1970, constituant en corporation : Elcftherios Sikiniolis, 3525, Barclay, app.4, (Jeorge Karabinos, tous deux restaurateurs, et Christina Sotiropoulou, marchande publique, épouse dudit George Karabinos, ces deux derniers du 6985, Durochcr, app.7, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: S'établir restaurateurs, sous le nom dc « Korba Pizzeria Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires de 810 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-mini.*! re des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippe Bouchard.38854 5382-1970 L.M.B.Industries Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation: Mayer Meisels, 4678, boulevard Notre-Dame, Laval, Ralph Meisels, tous deux marchands, et Priva Trachtcnberg, ménagère, épouse dudit Ralph Meisels, ces deux derniers du 6615, de Vimy, Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce dc toutes sortes de matières textiles, tissus, fils, laine et étoffes, sous le nom dc « L.M.B.Industries Incorporated », avec un capital total de $40,000, divisé en 5,000 actions ordinaires «le $1 chacune et 3,500 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social «le la compagnie est 3863, rue Lcsage, Verdun, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiii.ippK Bouchard.38854 5762-1970 Lcedan Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8c jourde janvier 1971, constituant en corporation: Samuel Moskovitch, 5564, Alpine, Cote Saint-Luc, David Litncr, 4501 ouest, rue Sherbrooke, app.3F, Wcstmount, tous deux avocats, Ester Mishkin, 4855, chemin «le la côte Sainte-Catherine, Montréal, et Ida Larocquc, 66, 13e Avenue, Dcux-Montagncs, ce-; deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie de placement, sous le nom de « Leedan Corporation », avec un capital total de S40.000, divisé en 2.000 actions ordinaires de $1 chacune, 30,000 actions privilégiées classe « A » de 81 chacune et 8,000 actions privilégiées classe « B » dc $1 chacune.Korba Pizzeria Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bcuring date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Elcftherios Sikiniotis, 3525 Barclay, Apt.4, George Karabinos, both restaurateurs, and Christina Sotiropoulou, public merchant, wife of the said George Karabinos, the latter two of 6985 Durochcr, Apt.7, all three of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Korba Pizzeria Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 4,000 common shares of $10 ach.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 53S2-1970 L.M.B.Industries Incorporated Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Mayer Meisels, 4678 Notre-Dame boulevard, Laval, Ralph Meisels, both merchants, and Priva Trachtcnberg, housewife, wife of the said Ralph Meisels, the latter two of 6615 dc Vimy, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of fabrics, textiles, threads, yarns and materials, under the name of \"L.M.B.Industries Incorporated\", with a total capital stock of 840,000, divided into 5,000 common shares of SI each and 3,500 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 3863 Lcsage Street, Verdun, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5762-1970 I iidan Corporation Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the Sth day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies nnd Cooperatives, incorporating: Samuel Moskovitch, 5564 Alpine, Côte Saint-Luc, David Litncr, 4501 Sherbrooke Street West, Apt.3F, Westmount, both advocates, Ester Mishkin, 4855 Côte Ste-Cathcrine Road, Montreal, and Ida Larocque, 66, 13th Avenue, Deux-Montugnes, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Lecdan Corporation\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $1 each, 30,000 class \"A\" preferred shares of 81 each and 8,000 class \"B\" preferred shares of SI each. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 1985 Le siège social de la compagnie est au 223, avenue Kindersley, Mont-Royal, district judiciaire de Montréal.Le xou.i-miui.ilrc (Ici institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Mouchard.38854 .96-1971 Locadent inc.Ia: ministre des institutions financières, compagnies cl coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Ghislain Larochclle, vendeur, Raymondc Paré, ménagère, épouse dudit Ghis-lain Larochclle, tous deux dc 8057, Comtois, Saint-Léonard, et Armel Robcrgc, dentiste, 837, Provost Drive, Ottawa, pour les objets suivants: Faire le commerce et la location d'instruments dentaires, chirurgicaux et médicaux, sous le nom de « Locadent inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 500 actions ordinaires d'une valeur nominale de S10 chacune et en 3,500 actions privilégiées d'une valeur nominale dc S10 chacune.Le siège social de la compagnie est 7160, boulevard Pie IX, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies el coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5479-1970 Loyola of Montreal Alumni Association Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12c jour dc janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Robcrt-G.Beauregard, 3014, rue Biret, Saint-Laurent, Brian O'N.Gallery, 19, chemin dc Casson, et Desmond Lartique, 145 nord, avenue Brock, ces deux derniers de Montréal, tous trois administrateurs, pour les objets suivants: Organiser, diriger et encourager les organisations, projets et manifestations, et faire toutes choses utiles à la promotion et à l'amélioration des intérêts et du bien-être du groupe « Loyola of Montreal », sous le nom de « Loyola of Montreal Alumni Association Inc.».Le montant auquel doit se limiter la valeur des biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de 81,000,000.\u2022 Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5130-1970 M E M Travel Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc décembre 1970, consti- Thc head office of the company is at 223, Kindersley Avenue, Mount Royal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 96-1971 Locadent inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ghislain Larochclle, salesman, Raymondc Paré, housewife, wife of said Ghislain Larochclle, both of 8057 Comtois, Saint-Léonard, and Armel Robcrgc, dentist, 837 Provost Drive, Ottawa, for the following purposes: To deal in and rent dental, surgical and medical instruments, under the name of \"Locadent inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 500 common shares of a nominal value of 810 each and into 3,500 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at 7160 Pic IX Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5479-1970 Loyola of Montreal Alumni Association Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Robert-G.Beauregard, 3014 Birct Street, Saint-Laurent, Brian O'N.Gallery, 19 de Casson Road, and Desmond Lartique, 145 Brock Avenue North, the latter two of Montreal, all three executives, for the following purposes : To organize, conduct and encourage organizations, projects, events and do all other things necessary and useful to promote and further the interests and welfare of the Loyola of Montreal community, under the name of \"Loyola of Montreal Alumni Association Inc.\".The amount to which the value of the immovable property which the corporation may hold or own is to be limited is 81,000,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5130-1970 M E M Travel Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, in- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, £7 février 1971, 108' année, n° 9 1986 tuant en corporation: Boris J.Berbrier, 4851, rue Fui-ton, Montréal, Horace Friedman, 7497, chemin Briar, et Barry A.Cappcl, 5891, Centennial, ces deux derniers de Côte Saint-Luc, tous trois avocats, pour les objets suivants: _ Etablir et diriger un bureau général de vente de billets et une agence dc voyages dans toutes ses spécialités, sous le nom de « M E M Travel Ltd.», avec un capital total dc SlOO.OOO, divisé en 3,000 actions ordinaires de 810 chacune et 7,000 actions privilégiées de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54 5661-1970 Maxinvest Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Douglas Duncan, comptable agréé, 35, Church Hill, Joe Coogan, comptable, 2750, avenue Kent, Robert Lee, métallurgiste, 11250, Su/.or-Côté, tous trois de Montréal, et Pierre Allard, administrateur, 185, rue Vimy, Saint-Bruno-dc-Mon-taryille, pour les objets suivants: Etablir et diriger une compagnie dc placement, sous le nom dc « Maxinvest Inc.», avec un capital divisé en 5,000 actions ordinaires sans valeur au pair.I.¦ siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5640-1970 Maxi Poultry Co.Ltd.La Cie de volailles Maxi ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Léo Gold, restaurateur, 782, avenue du Sablon, Laval, Gcrry Boglcr, marchand, 4211, avenue Badgely, et Stephanie Mozes, comptable, veuve dc Arthur Mozes, 830, avenue Saint-Roch, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire l'élevage et le commerce de volailles, faire le commerce dc produits dc volailles, oeufs, couvoirs, aliments, nourriture, produits dc la ferme, produits agricoles, épiceries, articles et marchandises, sous le nom de « Maxi Poultry Co.Ltd.\u2014 La Cie de volailles Maxi ltée », avec un capital total de 8100,000, divisé en 10,000 actions ordinaires de $1 chacune et 90,000 actions privilégiées de $1 chacune.corporating: Boris J.Berbrier, 4851 Fulton Street, Montreal, Horace Friedman, 7497 Briar Road, and Barry A.Cappel, 5891 Centennial, the latter two of Côte Saint-Luc, all three advocates, for the following purposes: To carry on business as a general ticket agency and travel bureau in all its branches, under the name of \"M E M Travel Ltd.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 3,000 common shares of $10 each and 7,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at Saint-Laurent, judicial district of Montreal.Ls-PniLippE Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o ' 5661-1970 Maxinvest Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Douglas Duncan, chartered accountant, 35 Church Hill, Joe Coogan, accountant, 2750 Kent Avenue, Robert Lee, metallurgist, 11250 Suzor-Côté, all three of Montreal, and Pierre Allard, executive, 185 Vimy Street, Saint-Bruno-de-Montarville, for the following purposes: To carry on the business of an investment company, under the name of \"Maxinvest Inc.\", with a capital stock divided into 5,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5640-1970 Maxi Poultry Co.Ltd.La Cic de >olailIcs Maxi ltée ' Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 22nd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Léo Gold, restaurateur, 782 du Sablon Avenue, Laval, Gerry Bogler, merchant, 4211 Badgely Avenue, and Stephanie Mozes, bookkeeper, widow of Arthur Mozes, 830 St.Roch Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in poultry, poultry products, eggs, hatcheries, foods, foodstuffs, farm products, agricultural products, groceries, wares and merchandise, under the name of \"Maxi Poultry Co.Ltd.\u2014 La Cie de volailles Maxi ltée\", with a total capital stock of $100,000, divided into 10,000 common shares of $1 each and 90,000 preferred shares of $1 each. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5659-1970 Meubles Etchemin inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour dc janvier 1971, constituant en corporation: Yves Lachancc, comptable, Micheline Lapointe, ménagère, épouse dudit Yves Lachancc, Jean-Claude Aubin, technicien, et Colette Plante, ménagère, épouse dudit Jean-Claude Aubin, tous quatre de Lac Etchemin, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de meubles et nouveautés dc toutes sortes, sous le nom de « Meubles Etchemin inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 400 actions ordinaires de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Lac Etchemin, district judiciaire de Beauce.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 188-1971 Mislyn Hosiery Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Nick Schinas, homme d'aifaircs, Helen Sampson, ménagère, épouse dudit Nick Schinas, tous deux du 7355, L'Acadic, app.802, Montréal, Stylianos Stclliou, homme d'affaires, et Catherine Sampson, ménagère, épouse dudit Stylianos Stclliou, ces deux derniers du 6735, Barry, Brossard, pour les objets suivants: Exploiter des boutiques dc bas, chaussettes et lingerie, et y vendre, acheter et faire le commerce dc bas et accessoires vestimentaires, robes et vêtements pour dames, sous le nom dc « Mislyn Hosiery Ltd.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de 810 chacune et 2,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5460-1970 Montreal Meat Market Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Judah Lyon Wolofsky, 5714, Melling, Côte Saint-Luc, Leon Jedeikin, 65, chemin Stratford, Hampstead, et Mervyn Norman Rosenstein, 1987 The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5659-1970 Meubles Etchemin inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yves Lachancc, accountant, Micheline Lapointe, housewife, wife of said Yves Lachance, Jean-Claude Aubin, technician, and Colette Plante, housewife, wife of said Jean-Claude Aubin, all four of Lac Etchemin, for the following purposes: To manufacture and deal in furniture and novelties of all kinds, under the name of \"Meubles Etchemin inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 400 common shares of S100 each.The head office of the company is at Lac Etchemin, judicial district of Beaucc.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 188-1971 Mislyn Hosiery Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 10th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nick Schinas, businessman, Helen Sampson, housewife, wife of the said Nick Schinas, both of 7355 L'Acadie, Apt.802, Montreal, Stylianos Stclliou, businessman, and Catherine Sampson, housewife, wife of the said Stylianos Stclliou, the latter two of 6735 Barry, Brossard, for the following purposes: To operate hosiery shops, and to buy, sell and deal in hosiery and women's wear and dress accessories, under the name of \"Mislyn Hosiery Ltd.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 2,000 common shares of a par value of $10 each and 2,000 preferred shares of a par value of 810 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5460-1970 Montreal Meat Market Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Judah Lyon Wolofsky, 5714 Melling, Côte Saint-Luc, Leon Jedcikin, 65 Stratford Road, Hampstead, and Mervyn Norman Rosenstein, 1307 19SS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 1307, nie Beauvais, Saint-Laurent, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire le commerce dc viandes, bestiaux, moutons, porcs, beurre, poissons, et tous les aliments d'une façon générale, et peaux, fourrures, cuirs, graisses, engrais, sabots, fumier et autres produits de l'animal, produits laitiers, produits de la ferme et du jardin, sous le nom de « Montreal Meat Market Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 20,000 actions ordinaires dc $1 chacune et 20,000 actions privilégiées de SI chacune.Le siège social dc la compagnie est au 0108, Jean Milot.Lasalle, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54 5546-1970 Montroil Resources Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coo]>éralives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Robert A.Hope, 562, avenue Grosvcnor, Wcstmount, Richard .LE.Bowie, 181, avenue Morrison, Mont-Royal, et C.Stephen Chcaslcy, 341, Berkeley Circle, Dorval, tous trois avocats, pour les objets suivants: Faire dc la prospection, de l'exploration pour trouver de l'huile, du pétrole, naphte, gaz naturel et minerai, métaux et minéraux de toutes sortes et en faire le commerce, sous le nom dc « Montroil Resources Ltd.», avec un capital divisé en 5,000,000 actions sans valeur au pair.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5524-1970 I N.D.P.Donuts Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour d'octobre 1970, constituant en corporation: Nick Georgoudis, 6939, Outre-mont, app.5, Dimitrios Georgoudis, 6988, Wiseman, app.2, et Peter Georgoudis, 6943, Outremont, app.4, tous trois administrateurs, dc Montréal, pour les objets suivants: S'établir boulangers, confiseurs et manufacturiers de biscuits, sous le nom de « N.D.P.Donuts Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de S10 chacune et 2,000 actions privilégiées dc S10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 1180, boulevard Décaric, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sons-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 4641-1970 Beauvais Street, Saint-Laurent, all three advocates, for the following purposes: To deal in meat, cattle, sheep, hogs, butter, fish and all food produce generally and skins, hides, furs, leather, fat, fertilizers, hoofs, manures and other animal products and dairy, farm and garden produce of all kinds, under the name of \"Montreal Meat Market Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and 20,000 preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 0108 Jean Milot, Lasalle, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5546-1970 Montroil Resources Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Robert A.Hope, 562 Grosvcnor Avenue, West-mount, Richard .I.E.Bowie, 181 Morrison Avenue, Mount Royal, and C.Stephen Cheaslcy, 341 Berkeley Circle, Dorval, all three advocates, for the following purposes: To prospect, explore and deal in oil, petroleum, naphta and natural gases and ores, metals and minerals of all kinds, under the name of \"Montroil Resources Ltd.\", with a capital stock divided into 5,000,000 shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 5524-1970 N.D.P.Donuts Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, bearing date the 23rd day of October.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Nick Georgoudis, 6939 Oulremont, Apt.5, Dimitrios Georgoudis, 6988 Wiseman, Apt.2, and Peter Georgoudis, 6943 Outremont, Apt.4, all three executives, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as bakers, confectioners ond biscuit manufacturers, under the name of \"N.D.P.Donuts Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of $10 each und 2,000 preferred shares of $10 each.The head office of the company is at 1180 Décarie Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 4641-1970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 L'Opéra du Quebec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 30c jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Gérard I.a ma relie, directeur général, 930, Hartland, Outremont, Leopold Simoncau, directeur adjoint, 497, avenue des Bouleaux.Saint-Bruno-de-Montarvillc, et Guy Beaul-nc, directeur général, 1155, Bougainville, Québec, pour les objets suivants: Promouvoir le théâtre lyrique, sous le nom de « L'Opéra du Québec».Le montant auquel sont limités les revenus annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est dc $1,000,000.Le siège social de la corporation est Place des Arts, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5650-1970 Orpheus Film Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour dc janvier 1971, constituant en corporation Barnabas Vi/.kelcty, 4426, chemin Circle, J.-Clovis Dagenais, 3549, Northcliffe, tous deux avocats, et Helen Adam, secrétaire, épouse de Manfred Adam, 4462, rue Padouc, tous trois de Montréal, pour les objets suivants: S'établir éditeurs de films et exploiter des studios de montage dc films, sous le nom dc < Orpheus Film Lttl.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc $10 chacune et 3,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est au 1445, rue du Fort, app.309, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 , 5648-1970 l'.mellol.l (Canada) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu «le la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Marcel Turgeon, industriel, Marthe Fortier, ménagère, épouse dudit Marcel Turgeon, tous deux de 1446, du Buisson, Sillery, et Séverin Lachapelle, avocat, 350, boulevard Charest est, suite 706, Québec, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce dc toutes sortes de portes, fenêtres et autres ouvertures, sous le nom de « Panclfold (Canada) inc.», avec un capital total de $200,000, divisé en 6,000 actions ordinaires de $10 chacune et en 14,000 actions privilégiées de $10 chacune.1989 L'Opéra du Québec Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo|ierativcs to incorporate a corporation without share capital: Gérard La-marchc, general manager, 936 Hartland, Outrcmont, Leopold Simoncau, assistant manager, 497 Bouleaux Avenue, Saint-Bruno-dc-Montarvillc, and Guy Bi aulne, general manager, 1155 Bougainville, Québec, for the following purposes: To promote an opera-house, under the name of \"L'Opéra du Québec\".The amount to which is limited the annual revenue of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $1,000,000.The head office of the corporation is at Place des Arts, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5650-1970 Orpheus Film Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Coo]>cratives, incorporating: Barnabas Vizkclety, 4426 Circle Road, J.-Clovis Dagenais, 3549 Northcliffe, both advocates, and Helen Adam, secretary, wife of Manfred Adam, 4462 Padoue Street, all three of Montreal, for the following purposes: .To carry on the business of motion picture producers and to operate motion picture studios, under the name of \"Orpheus Film Ltd.\", with a total capital stock of S40.000.divided into 1,000 common shares of S10 each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 1445 Fort Street, Apt.309, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5648-1970 Panelfol.l (Canada) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Marcel Turgeon, industrialist, Marthe Fortier, housewife, wife of said Marcel Turgeon both of 1446 du Buisson, Sillery, and Séverin Lachapcllc, advocate, 350 Charest Boulevard East, suite 706, Québec, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of doors, windows and other openings, under the name of \"Panclfold (Canada) inc.\", with a total capital stock of $200,000, divided into 6,000 common shares of $10 each and into 14,000 preferred shares of $10 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 87 février 1971, 103' année, n\" 9 1990 Le siège social de la compagnie est 599, 8e rue, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 137-1971 Park Place Dell - Restaurant Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Seymour Luterman, 26, Roxton Crescent, Montréal-Ouest, Leslie I.Notkin, 3742, Le Boulevard, Wcstmount, tous deux avocats, et Laura Firestone, secrétaire, fille majeure, 301, boulevard Dcguire, app.346, Saint-Laurent, pour les objets suivants: Tenir un restaurant, sous le nom de « Park Place Deli - Restaurant Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5574-1970 Peck Service Station inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Denis Doyon, mécanicien, 10842, Brunet, Montréal-Nord, Marcel Chapleau, homme d'affaires, 183, Roussille, Terrebonne, et Claude Guay, homme de service, 11841, Georges Pichet, Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'automobiles, moteurs, machines et tous leurs accessoires et parties, sous le nom de « Peck Service Station inc.», avec un capital total de S40,000, divisé en 150 actions ordinaires de S100 chacune et en 250 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est 5455, St-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-o 5674-1970 Perfection Ornemental and Iron Works Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de décembre 1970, constituant en corporation: Giakoumis Makris, plombier, 2959, Somerset, Saint-Laurent, Demetre Trevlos, commis, 332, Grosvenor, Westmount, et Angelo Michlopoulos, manufacturier, 955 ouest, de Liège, Montréal, pour les objets suivants: The head office of the company is at 599, 8th Street, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 137-1971 Park Place Deli - Restaurant Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Seymour Lutcrman, 26 Roxton Crescent, Montreal West, Leslie I.Notkin, 3742 The Boule-, vard, Westmount, both advocates, and Laura Firestone, secretary, spinster, 301 Dcguire Boulevard, Apt.346, Saint-Laurent, for the following purposes: To operate a restaurant, under the name of \"Park Place Deli - Restaurant Inc.\", with a total capital stock of S40.000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 30,000 preferred shares of a par value of $1 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 .5574-1970 Peck Service Station inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Denis Doyon, mechanic, 10842 Brunet, Montreal-North, Marcel Chapleau, businessman, 183 Roussille, Terrebonne, and Claude Guay, attendant, 11841 Georges Pichet, Montreal, for the following purposes : To carry on business as garage keepers and to deal in automobiles, motors, machines and all their accessories and parts, under the name of \"Peck Service Station inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 150 common shares of $100 each and into 250 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at 5455 St-Laurent, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5674-1970 Perfection Ornemental and Iron Works Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Giakoumis Makris, plumber, 2959 Somerset, Saint-Laurent, Demetre Trevlos, clerk, 332 Grosvenor, Westmount, and Angelo Michlopoulos, manufacturer, 955 Liège West, Montreal, for the following purposes: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 S'établir manufacturiers, marchands, intermédiaires, importateurs, exportateurs et entrepreneurs de ferronnerie ornementale, comprenant des rampes de balcons, garde-fou, grilles, balustrcs d'escaliers et autres produits semblables, sous le nom de « Perfection Ornamental and Iron Works Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires de 810 chacune et 200 actions privilégiées de 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est au 4857, avenue du Parc, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5488-1970 Roger Pilon construction inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 18e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Roger Pilon, constructeur, 565, Alexis Nihon, Saint-Laurent, Alfred Napier, administrateur, 2444, Benny Crescent, et Jean-Charles Bernard, gérant général, 5521, Beaugrand, ces deux derniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires comme entrepreneurs généraux en construction et faire le commerce de toutes sortes de matériaux, sous le nom de « Roger Pilon construction inc.», avec un capital total de 8100,000, divisé en 1,000 actions ordinaires dc 8100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Dollard-des-Ormeaux, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5603-1970 Place Vieille Capitale inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7e jour de janvier 1971, constituant en corporation : Henri LaRue, 2660, Des Forges, Forges, Alphonse Laçasse, 3339, Hcrtel, tous deux de Sainte-Foy, Gratien Boily, 950, avenue Bougainville, et Paule Gauthier, fille majeure, 630, Père Marquette, ces deux derniers de Québec, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et de construction, sous le nom de « Place Vieille Capitale inc.», avec un capital total de 8200,000, divisé en 4,000 actions classe « A » d'une valeur nominale de 810 chacune, 6,000 actions classe « B » d'une valeur nominale de 810 chacune et en 10,000 actions privilégiées d'une valeur nominale de 810 chacune.Le siège social de la compagnie est à Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Phicippe Bouchard.38854-o 93-1971 1991 To carry on the business of manufacturers, merchants, jobbers, importers, exporters and constractors of ornamental ironworks including balcony railings, staircase banisters and similar products, under the name of \"Perfection Ornamental and Iron Works Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of 8100 each.The head office of the company is at 4857 Park Avenue, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5488-1970 Roger Pilon construction inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 18th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Roger Pilon, builder, 565 Alexis Nihon, Saint-Laurent, Alfred Napier, administrator, 2444 Benny Crescent, and Jean-Charles Bernard, general manager, 5521 Beaugrand, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on business as general building contractors and to deal in all kinds of materials, under the name of \"Roger Pilon construction inc.\", with a total capital stock of 8100,000, divided into 1,000 common shares of 8100 each.The head office of the company is at Dollard-des-Ormeaux, judicial district of Montreal.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5603-1970 Place Vieille Capitale inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Henri LaRue, 2660 Des Forges, Alphonse Laçasse, 3339 Hertel, both of St.Foy, Gratien Boily, 950 Bougainville Avenue, and Paule Gauthier, spinster of the full age of majority, 630 Père Marquette, the latter two of Québec, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Place Vieille Capitale inc.\", with a total capital stock of 8200,000, divided into 4,000 class \"A\" shares of a nominal value of 810 each, 6,000 class \"B\" shares of a nominal value of 810 each and into 10,000 preferred shares of a nominal value of 810 each.The head office of the company is at St.Foy, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy M mister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 93-1971 1992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103- année, n\" 9 Praltc & Côté Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour dc décembre 1970, autorisant la fusion de la compagnie « Prattc & Côté Inc.», constituée en corporation par lettres patentés en date du 31e jour de décembre 195S, dc la compagnie « Lcsage, Protcau ltée », constituée par lettres patentes en date du lie jour de juin 193S, dc la compagnie « Pratte & Cic (Assurances) ltée \u2014 Prattc & Co.(Insurance) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 15e jour dc mars 1955, de la compagnie « Pratte & Cie (Assurances) Québec ltée \u2014 Pratte & Co.(Insurance) Québec Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 1-le jour de janvier 1958, de la compagnie « Houle, Méthot, Bédard & Associés liée », constituée par lettres patentes en date du 4c jour de janvier 1965, dc la compagnie « Courtiers {l'Assurance du Boulevard inc.\u2014 Boulevard Insurance Brokers Inc.», constituée par lettres patentes en date du 9e jour dc septembre 1960, et de la compagnie « Dozois, Morrissette inc.», constituée par lettres patentes en date du 26e jour de septembre 1957, toutes ces lettres patentes ayant été émises en vertu de ladite première partie dc la Loi des compagnies, pour les objets suivants: S'établir courtiers en assurances, sous le nom de « Pratte & Côté Inc.», avec un capital total dc 834,500, divisé en 34,500 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social dc la nouvelle compagnie est au 1135, chemin Saint-Louis, dans la ville dc Sillery, district judiciaire dc Québec.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard, 38854 5752-1970 Propane Gas Utilities (1970) Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes, en date du 31e jour dc décembre 1970, autorisant la fusion des compagnies « Propane Gas Utilities Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 26e jour de mars 1953, « Joliette Propane inc.\u2014 Propane Joliette Inc.», constituée pur lettres patentes en date du 23e jour de mai 1952, « Lauren tien Gas Propane limitée», constituée par lettres patentes en date du 5e jour d'octobre 1953, « Canadian Pargas (Rouanda) Limited \u2014 Pargas du Canada (Rouanda) limitée», constituée par lettres patentes en date du 22c jour d'octobre 1958, et «Pargas du Canada (Val d'Or) limitée \u2014 Canadian Pargas (Val d'Or) Limited », constituée par lettres patentes en date du 30e jour de janvier 1954, toutes ces lettres patentes ayant été émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Faire l'extraction, la fabrication, la transformation, la synthèse, la raffinerie, la production, le transport, l'importation, l'exportation, la mise en marché, l'achat, Prattc & Côté Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act.letters patent, dated the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Pratte & Côté Inc.\", incorporated by letters patent dated the 31st.day of December, 195S, \"Lcsage, Proteau ltée\", incorporated by letters patent dated the 11th day of June, 193S, \"Pratte & Cie (Assurances) ltée \u2014 Prattc & Co.(Insurance) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 15lh day of March, 1955, \"Praltc & Cie (Assurances) Quebec ltée \u2014 Prattc & Co.(Insurance) Québec Ltd.\".incorporated by letters patent dated the 14th day of January, 195S, \"Houle, Méthot, Bédard & Associés ltée\", incorporated by letters patent dated 4th day of January, 1965, \"Courtiers d'Assurance du Boulevard inc.\u2014 Boulevard Insurance Brokers Inc.\", incorporated by letters patent dated the 9th day of September, 1960, and \"Dozois, Morrissette inc.\", incorporated by letters patent dated the 26th day of September, 1957, all such letters patent having been issued under the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To carry on the business of insurance brokers, under the name of \"Pratte & Côté Inc.\", with a total capital .stock of 834,500 divided into 31,500 common shares of a par value of 81 each.The head office of the new company is at 1135 St.Louis Road, in the city of Sillery, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial fsntilulions.Companies and Cooperatives.38854-0 5752-70 Propane Gas Utilities (1970) Limited Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 31st.day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Propane Gas Utilities Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 26th day of March 1953, \"Joliette Propane inc.-\u2014 Propane Joliette Inc.\", incorporated by letters patent dated the 23rd day of May 1952, \"Laurenticn Gas Propane limitée\", incorporated by letters patent dated the 5th' day of October 1953, \"Canadian Pargas (Rouanda) Limited \u2014 Pargas du Canada (Rouanda) limitée\", incorporated by letters patent dated the 22nd day of October 195S, and \"Pargas du Canada (Val d'Or) limitée \u2014 Canadian Pargas (Val d'Or) Limited\", incorporated by letters patent dated the 30th day of January 1954, all such letters patent having been issued under the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To extract, manufacture, process, synthesize, refine, generate, transport, import, export, market, buy, sell and deal in and with goods, wares, merchandise and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 1993 la vente et le commerce d'articles, produits et marchandises, d'énergie et de sources d'énergie de toutes sortes et de toute nature, sous le nom de \" Propane Gas Utilities (1970) Limited », avec un capital divisé en 100,000 actions ordinaires sans valeur au pair, pourvu toutefois que les actions ordinaires aient été émises pour des provisions n'excédant pas en argent ou en valeurs la somme de S150,000.Le siège social de la nouvelle compagnie est au bureau 430, 100, d'Youville, Québec, district judiciaire dc Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5598-70 energy and sources of energy of any and every kind, under the name of \"Propane Gas Utilities (1970) Limited\", with a capital divided into 100,000 common shares without par value provided however that the common shares shall not be issued for a consideration exceeding in amount or value the sum of 8150,000.The head office of the new company is at Room 430, 100 d'Youville, Québec, judicial district of Québec.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-e 5598-70 Victor Prus Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 23c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Claude-Armand Sheppard, avocat, 5030, Glcncairn, Hugucttc Fournier, 8179, 10e Avenue, tous deux de Montréal, et.Claudine Proutat, 200, Corot, Ile-dcs-Soeurs, ces deux dernières secrétaires, filles majeures, pour les objets suivants: S'établir conseillers en administration, conseillers industriels et conseillers et experts dans l'exploitation de toutes sortes d'entreprises, sous le nom dc « Victor Prus Inc.», avec un capital total dc 840,000, ilivisé en 1,000 actions ordinaires de SI chacune et 3,000 actions privilégiées dc 810 chacune Le siège social dc la compagnie est 1290 ouest, avenue des Pins, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 5157-1970 Victor Prus Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 23rd day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Claude-Armand Sheppard, lawyer, 5030 Glencairn, Huguette Founder, 8179, 10th Avenue, both of Montreal, and Claudine Proutat, 200 Corot, Ile-des-Soeurs, the latter two secretaries, filles majeures, for the following purposes: To carry on business as management consultants, industrial consultants and advisers and consultants in the operation of all kinds of businesses, under the name of \"Victor Prus Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 1,000 common shares of 810 each and 3,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 1290 Pine Avenue West, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5157-1970 The Québec Chapter of « American Society of Architectural Hardware Consultants » Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4c jour dc janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: André Hains, 502, Surprenant, Drummondville, Rosaire Légaré.9232, André Grasset, Claude Lachancc, 1570, avenue des Queylus, tous deux de Montréal, Hubert Richard.466, Hervé, René Payette, 247, Forget, tous deux de Laval, et J.-D.Valère Haince, 6, boulevard Pic X, Lévis, tous conseillers en quincaillerie architecturale, pour les objets suivants: Grouper en association les conseillers en quincaillerie architecturale et promouvoir des rencontres et la coopération entre les membres, sous le nom de « The Québec Chapter of « American Society of Architectural Hardware Consultants ».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 8100,000.The Québec Chapter of \" American Society of Architectural Hardware Consultants \" Notice is given that under Part III of the Compagnies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: André Hains, 501 Surprenant, Drummondville, Rosaire Légaré, 9232 André Grasset, Claude Lachancc, 1570 Queylus Avenue, both of Montreal, Hubert Richard, 466 Hervé, René Payette, 247 Forget, both of Laval, and J.-D.Valère Haince, 6 Pie X Boulevard, Levis, all architectural hardware consultants, for the following purposes: To group into an association architectural hardware consultants and promote meetings and cooperation among the members, under the name of \"The Québec Chapter of \"American Society of Architectural Hardware Consultants\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation mav acquire and possess, is 8100,000. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 1994 Le siège social dc la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le .ions-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-u 4909-1970 Itcimcrs Automobile Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 7c jour de janvier 1971, constituant en corporation: Helmut Reimers, vendeur d'automobile, Frieda Reimers, ménagère, épouse dudit Helmut Reimers, tous deux du 867, rue Devonshire, et Joseph Assaf, comptable, 490, rue Saint-Jean-Baptistc, tous trois de Laval, pour les objets suivants: S'établir garagistes et faire le commerce de véhicules automobiles, camions, pièces dc moteurs, tracteurs, avions, moteurs d'avions, canots automobiles, radios, réfrigérateurs, bicyclettes, motocyclettes et accessoires, sous le nom de « Reimers Automobile Inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 10,000 actions ordinaires de SI chacune et 30,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Laval, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 84-1971 Le Rendez-Vous du Salarié Québécois Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du lie jour de janvier 1971, constituant en corporation sans capital-actions: Jules Ven-detti, commerçant, 6249, Molson, Richard Croteau, programmeur, 6200, 2e Avenue, Robert Mercure, dessinateur, 5992, 2e Avenue, et Jean-Pierre Collin, étudiant, 6338, Chateaubriand, tous quatre de Montréal, pour les objets suivants: Travailler à la promotion collective des salariés sur les plans économiques, sociaux, politiques et culturels et à leur progrès en général, sous le nom de « Le Rendez-Vous du Salarié Québécois».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation, est.de 8100,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5101-1970 Restaurant Jardin (Viau) inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour de janvier 1971, cons- The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 4909-1970 Reimers Automobile Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 7th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Helmut Reimers, automobile dealer, Frieda Reimers, housewife, wife of the said Helmut Reimers, both of 867 Devonshire Street, and Joseph Assaf, bookkeeper, 490 St.Jean Baptiste Street, all three of Laval, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in motor cars, motor trucks, motor parts, tractors, aircraft, aircraft motors, motor boats, radios, refrigerators, bicycles, motorcycles and accessories, under the name of \"Reimers Automobile Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of the par value of 81 each and 30,000 preferred shares of the par value of 81 each.The head office of the company is at Laval, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 84-1971 Le Rendez-Vous du Salarié Québécois Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 11th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jules Vcndctti, trader, 6249 Molson, Richard Croteau, programmer, 6200, 2nd Avenue, Robert Mercure, draftsman, 5992, 2nd Avenue, and Jean-Pierre Collin, student, 6338 Chateaubriand, all four of Montreal, for the following purposes: To aim for the collective promotion of wage-earners on the economical, social, political and cultural levels and for their progesss in general, under the name of \"Le Rendez-Vous du Salarié Québécois\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is 8100,000.The head office of the corporation is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5101-1970 Restaurant Jardin (Viau) inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 tituant en corporation: Denis Kakaroubas, 7990 est, Sherbrooke, Nick Mcllas, 7959 est, Hochelaga, app.206, ct Spiros Basitis, 9175, Meunier, tous trois restaurateurs, de Montréal, pour les objets suivants: S'établir restaurateurs, sous le nom de « Restaurant Jardin (Vian) inc.», avec un capital total dc $40,000, divisé en 10,000 actions classe « A » de $1 chacune et 10,000 actions classe « B » dc $1 chacune, 10,000 actions privilégiées classe « A » de $1 chacune et 10,000 actions privilégiées classe « B » de SI chacune.Le siège social de la compagnie est au 8705, boulevard Viau, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 5628-1970 Restaurants Renaissance inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 17c jour dc novembre 1970, constituant en corporation: André Valiqucttc, 59, Franklin, Daniel Kochenburger, 1545, boulevard Graham, tous deux de Mont-Royal, Michel Blouin, 3328, avenue Troie, ct Michel Duranccau, 5775, Darlington, ces deux derniers de Montréal, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Faire affaires comme restaurateurs, sous le nom de « Restaurants Renaissance inc.», avec un capital total de S40.000, divisé en 20,000 actions ordinaires de $1 chacune et en 200 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-miiiistre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5054-1970 Itoscbridge Importing Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Daniel Kingstone, 4985, Iona, Gilles Poulin, 103, Ashton, et André Larivière, 3101, Édouard-Montpelit, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes de produits, articles et marchandises, sous le nom de « Rose-bridge Importing Co.Ltd.», avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires sans valeur au pair.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5444-1970 N.Rubin (1971) Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première 1995 incorporating: Denis Kakaroubas, 7990 Sherbrooke East, Nick Mcllas, 7959 Hochelaga East, Apt.206, and Spiros Basitis, 9175 Meunier, all three restaurateurs, of Montreal, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurant Jardin (Viau) inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 class \"A\" shares of $1 each, 10,000 class \"B\" shares of $1 each, 10,000 class \"A\" preferred shares of $1 each and 10,000 class \"B\" preferred shares of $1 each.The head office of the company is at 8705 Viau Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5628-1970 Restaurants Renaissance inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 17th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: André Valiquette, 59 Franklin, Daniel Kochenburger, 1545 Graham Boulevard, both of Mount Royal, Michel Blouin, 3328, Troie Avenue, and Michel Duranceau, 5775 Darlington, the latter two of Montreal, all four advocates, for the following purposes: To carry on business as restaurateurs, under the name of \"Restaurants Renaissance inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 20,000 common shares of $1 each and into 200 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5054-1970 Roscbridge Importing Co.Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 9th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Daniel Kingstone, 4985 Iona, Gilles Poulin, 103 Asbton, and André Larivière, 3101 Édouard-Mont-petit, all three advocates, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of products, articles and merchandise, under the name of \"Rose-bridge Importing Co.Ltd.\", with a capital stock divided into 40,000 common shares without par value.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5444-1970 N.Rubin (1971) Ltd.Noice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of Decern- 1996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n' 9 partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 2lc jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Michael Garber, 4338, Montrose, Westmount, Harry Y.Garber, 141 sud, Ballantyne, Montréal-Ouest, tous deux avocats, et Irene Rubin, secrétaire, fille majeure, 5552, avenue Snowdon, app.17.Montréal, pour les objets suivants: L'industrie et le commerce de toutes sortes dc cuirs, peaux dc toutes sortes ct d'imitations naturelles ou artificielles, sous le nom dc « N.Rubin (1971) Ltd.», avec un capital total dc 840,000, divisé en 20,000 actions ordinaires de SI chacune et 2,000 actions privilégiées dc $10 chacune.Le siège social dc la compagnie est 6600, rue Saint-Urbain, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5649-1970 ber, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Michael Garber, 4338 Montrose, Westmount, Harry Y.Garber, 141 Ballantyne South, Montreal West, both advocates, and Irene Rubin, secretary, spinster.5552 Snowdon Avenue, Apt.17, Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in all kinds of leathers, pelts, hides, kips, and skins, and natural or artificial substitutes, under the name of \"N.Rubin (1971) Ltd.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 20,000 common shares of SI each and 2,000 preferred shares of S10 each.The head office of the company is at 6600 St.Urbain Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piulippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-u 5649-1970 Si.Luwrence Fuel (1970) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé «les lettres patentes, en «laie du 31e jour dc décembre 1970.autorisant la fusion des compagnies suivantes: « Pétroles Lion Fuels Inc.», constituée par lettres patentes en date du 10e jour de décembre 1954, « Charbonncrie St-Laurcnt inc.\u2014 St.Lawrence Fuel Inc.», constituée par lettres patentes en date du 26c jour de mai 1966.« Ideal Petroleum (1959) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 1er jour de décembre 1959.« Par-A-Gaz-Paradis Inc.», constituée par lettres patentes en date du 30c jour de décembre 1966, « Lcmoyne Oil Co.Inc.», constituée par lettres patentes en date du lie jour de novembre 1959, « Varennes Terminais Ltd.«, constituée par lettres patentes en date du 14e jour de janvier 1956, et « Duico Inc.», constituée par lettres patentes en date du 1er jour d'avril 1965; toutes ces lettres patentes ont été émises en vertu de ludite première partie «le la Ix)i des compagnies, pour les objets suivants: Faire l'extraction, la fabrication, la transformation, la synthèse, la radinerie, la production, le transport, l'importation, l'exportation, la mise en marché, l'achat, la vente et le commerce d'articles, produits et marchandises, d'énergie et «le sources d'énergie de toutes sortes et de toutes nature, sous le nom dc « St.Lawrence Fuel (1970) Inc.», avec un capital divisé en 500,000 actions ordinaires sans valeur au pair, pourvu toutefois que les actions ordinaires soient émises pour des provisions ne dépassant pas en argent ou en valeur la somme de 8500,000.Le siège social de la nouvelle compagnie est au bureau 430, 100, d'Youville, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5596-70 St.Lawrence Fuel (1970) lue.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 31st day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Pétroles Lion Fuels Inc.\", incorporated by letters patent dated the 10th day of December, 1954, \"Charbonncrie St-Laurcnt inc.\u2014 St.Lawrence Fuel Inc.\", incorporated by letters patent dated the 26th day of May 1966, \"Ideal Petroleum (1959) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 1st day of December, 1959, \"Par-A-Gaz-Paradis Inc.\", incorporated by letters patent dated the 30th day of December 1966, \"Lcmoync Oil Co.Inc.\".incorporated by letters patent dated the 11th day of November 1969.\"Varennes Terminals Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 14th day of January 1956, and \"Daico Inc.\", incorporated by letters patent dated the 1st day of April 1965, all such letters patent having been issued under the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To extract, manufacture, process, synthesize, refine, generate, transport, import, export, market, buy, sell and deal in and with goods, wares, merchandise and energy and sources of energy of any and every kind, under the name of \"St.Lawrence Fuel (1970) Inc.\".with a capital divided into 500,000 common shares without par value provided however that the common shares shall not be issue«l for a consideration exceeding in amount or value the sum of 8500.000.The head office of the new company is at Room 430, 100 d'Youville, Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38S54-0 5596-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 1997 St-Paiil linndug, inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de novembre 1970, constituant en corporation: Maurice Martel, Paul Martel, tous deux avocats, de 1301, St-Viateur ouest, Outremont, et Lucille Roy, secrétaire, épouse dc Jean-Claude Biais, 24, Gilles, Saintc-Thérèsc-Ouest, pour les objets suivants: Fabriquer et faire le commerce de pneus, sous le nom dc « St-Paul Bandag, inc.», avec un capital total dc S40.000, divisé en 2,000 actions ordinaires d'une valeur nominale dc 810 chacune ct en 200 actions privilégiées d'une valeur nominale dc SI00 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Saint-Paul-d'Abbotsford, district judiciaire dc Saint-Hyacinthe.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854-0 4962-1970 Sarlian & Co.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ali M.Kanso, 9905, Saint-Laurent, Montréal, Ahmad Ali Sarhan, tous deux marchands, ct Gnayat Kunso, ménagère, épouse dudit Ahmad Ali Sarhan, ces deux derniers du 910, rue Paris, Brossard, pour les objets suivants: Établir et diriger un magasin général, sous le nom de « Sarhan & Co.Inc.».avec un capital total dc S40.000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S100 chacune ct 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de S10 chacune.Le siège social de la compagnie est au 3531, boulevard Saint-Laurent, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5303-1970 St-Paul Randag, inc.Notice is given that under Purl I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Maurice Martel, Paul Martel, both udvocates, of 1301 St-Viuteur West, Outremont, and Lucille Roy, secretary, wife of Jeun-Claude Biais, 24 (ïillcs, Sainte-Thérèse-West, for the following purposes: To manufacture and deal in tires, under the name of \"St-Paul Bandag, inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 2,000 common shares of a nominal value of 810 each and 200 preferred shares of a nominal value of $100 each.The head office of the company is at Saint-Paul d'Abbotsford, judicial district of Saint-Hyacinthe Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 4962-1970 Sarhan & Co.Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, hearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ali M.Kanso, 9905 St.Lawrence, Montreal, Ahmad Ali Sarhan, both merchants, and Gnayat Kanso, housewife, wife of the said Ahmad Ali Sarhan, the latter two of 910 Paris Street, Brossard, for the following purposes: To carry on the business of a department store, under the name of \"Sarhan & Co.Inc.\", with a total stock of $40,000.divided into 1,000 common shares of n par value ot $10 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at 3531 St.Lawrence Boulevard, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5303-1970 Joseph Sa era/in Clothing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopérative donne avis, qu'en vertu de lu première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 28c jour de décembre 1970, constituant en corporation : Picrrc-L.Lapointe, 155, Marcotte, Saint-Laurent, Mark M.Rosenstcin, 5003, Lacombe, Montréal, ct Thomas A.Lavin, Knowlton, tous trois avocats, pour les objets suivants: Manufacturer ct faire le commerce dc vêtements de toutes sortes, sous le nom dc * Joseph Sarrazin Clothing Inc.», avec un capital total dc S40.000.divisé en 4,000 actions ordinaires de S10 chacune Joseph Sarrazin Clothing Inc.Notice i» given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 28th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Pierre-L.Lapointe, 155 Marcotte, Saint-Laurent, Mark M.Rosentein, 5003 Lacombe, Montreal, and Thomas A.Lavin, Knowlton, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in clothing of all kinds, under the name of \"Joseph Sarrazin Clothing Inc.\", with a total capital stock of 840,000, divided into 4.000 common shares of 810 each. 1998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Le siège social de la compagnie est à Saint-Gabriel, comté de Bcrthicr, district judiciaire de Joliette.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5727-1970 The head office of the company is at Saint-Gabriel, county of Berthicr, judicial district of Joliette.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 .5727-1970 Service d'cxpnnsion économique et industrielle (Trois-Rivières) inc.Business and Industrial Development Board (Trois-Rivières) Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13c jour de novembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Jean-Paul Lamy, comptable agréé, 3941, de la Sapinière, James-F.Savard, ingénieur, 3280, Calais, Jacques Charette, assistant-gérant municipal, 750, des Saules, Jean-Paul Bellemare, conseiller en administration, 858, Laviolette, Harrold J.Tebbutt, industriel, 2665, Tessier, Jean-Guy Cyr, 501, St-Maurice, et Gilles Beaudoin, 1890, Lajoie, ces deux derniers hommes d'affaires, tous de Trois-Rivières, pour les objets suivants: Promouvoir ct faciliter la conservation, l'expansion, le développement des entreprises industrielles, commerciales ou touristiques de la cité dc Trois-Rivières, sous le nom de « Service d'expansion économique et industrielle (Trois-Rivières) inc.\u2014 Business and Industrial Development Board.(Trois-Rivières) Inc».Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir ct posséder est de $100,000.Le siège social de la corporation est à Trois-Rivières, district judiciaire de Trois-Rivières.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 2830-1970 Service d'expansion économique ct industrielle (Trois-Rivières) inc.Business and Industrial Development Board (Trois-Rivicrcs) Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 13th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Jean-Paul Lamy, chartered accountant, 3941 de la Sapinière, James-F.Savard, engineer, 3280 Calais, Jacques Charette, assistant municipal manager, 750 des Saides, Jean-Paul Bellemare, management consultant, 858 Laviolette, Harrold J.Tebbutt, industrialist, 2665 Tessicr, Jean-Guy Cyr, 501 St-Mauricc, and Gilles Beaudoin, 1890 Lajoie, the latter two businessmen, all of Trois-Rivières, for the following purposes: To promote and facilitate the conservation, expansion and development of the industrial, commercial or touristic undertakings of the city of Trois-Rivières, under the name of \"Service d'expansion économique ct industrielle (Trois-Rivières) inc.\u2014 Business and Industrial Development Board (Trois-Rivières) Inc.\".The amount to which is limited the value of the immovable property which the corporation may acquire and possess, is $100,000.The head office of the corporation is at Trois-Rivières.judicial district of Trois-Rivières.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutioiis, Companies and Cooperatives.38854 ' 2830-1970 Servimax inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour dc décembre 1970, constituant en corporation: Jean-André Morin, commerçant, Hélène Aubry, comptable, épouse dudit Jean-André Morin, ct Andrée Morin, hôtesse, fille majeure, tous trois dc 11, Bord dc l'Eau, Repentigny, pour les objets suivants: Faire affaires comme épiciers, sous le nom de « Servimax inc.», avec un capital total de $500,000, divisé en 1,500 actions ordinaires de $10 chacune et en 970 actions privilégiées de $500 chacune.Le siège social de la compagnie est 11, rue Bord de l'Eau, Repentigny, district judiciaire de Joliette./,e sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 26-1971 Servimax inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29 th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Jean-Ajidré Morin, trader, Hélène Aubry, accountant, wife of said Jean-André Morin, and Andrée Morin, hostess, spinster of the full age of majority, all three of 11 Bord de l'Eau, Repentigny, for the following purposes: To carry on business as grocers, under the name of \"Servimax inc.\", with a total capital stock of $500,000, divided into 1,500 common shares of $10 each and 970 preferred shares of $500 each.The head office of the company is at 11 Bord de l'Eau Street, Repentigny, judicial district of Joliette.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 26-1971 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 1999 Sew and Save Shop Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 15e jour de décembre 1970, constituant en corporation : Harry Blank.4625, Miller, Sol B.Apel, 2657, Ekers, tous deux dc Montréal, et Irving Adessky, 56, Heath, Hampstead, tous trois avocats, I>our les objets suivants: L'industrie et le commerce de vêtements et accessoires pour dames, hommes et enfants, sous le nom de « Sew and Save Shop Ltd.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune._Le_ siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5534-1970 Raymond Trudel inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 4e jour «le janvier 1971, constituant en corporation: Raymond Trudel, commerçant, Hildegarde Rouleau, ménagère, épouse dudit Raymond Trudel, tous deux «le 131, 3e Avenue est, ct Jean I.abrecque, gérant, 301, Taschereau, tous trois d'Amos, pour les objets suivants: Faire affaires comme compagnie d'immeuble et «le construction, sous le nom de « Raymond Trutlel inc.», avec un capital total de $100,000, divisé en 200 actions ordinaires de $100 chacune ct en 800 actions privilégiées de $100 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Amos, district judiciaire «PAbitibi.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54-o 5645-1970 Unique Plumbing & Healing Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie «le la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 12e jour «le janvier 1971, constituant en corporation: liai m Kafka, 937, avenue Châtelaine, Laval, Abraham Kafka, 4780, rue Vézina, app.34, tous deux plombiers, et Xalman Jegergarn, ven«leur, 5510, avenue Lavoie, ces deux tlerniers de Montréal, pour les objets suivants: Faire affaires dans la plomberie, le chauffage et la ventilation, sous le nom de « Unique Plumbing & Heating Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 10,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune et 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de $10 chacune.Sew and Save Shop Ltd.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 15th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Harry Blank, 4625 Miller, Sol B.Apel, 2657 Ekers, both of Montreal, and Irving Adessky, 56 Heath, Hampstead, all three advocates, for the following purposes: To manufacture and deal in women's, men's and children's apparel and accessories, under the name of \"Sew and Save Shop Ltd.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5534-1970 Raymond Trudel inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 4th day of January, 1971, have been issuc«l by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Raymond Trudel, trader, Hildegarde Rouleau, housewife, wife of said Raymond Trudel, both of 131, 3rd Avenue East, and Jean Labrecque, manager, 301 Taschereau, all three of Amos, for the following purposes: To carry on business as a real estate and construction company, under the name of \"Raymond Trudel inc.\", with a total capital stock of $100,000, divided into 200 common shares of $100 each and into 800 preferred shares of $100 each.The head office of the company is at Amos, judicial district of Abitibi.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5645-1970 Unique Plumbing & Healing Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 12th day of January, 1971, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Haim Kafka, 937 Châtelaine Avenue, Laval, Abraham Kafka, 4780 Vézina Street, Apt.34, both plumbers, and Zalman Jegergarn, salesman, 5510 Lavoie Avenue, the latter two of Montreal, for the following purposes: To carry on the business of plumbing, heating and ventilation, under the name of \"Unique Plumbing & Heating Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 10,000 common shares of a par value of $1 each and 3,000 preferred shares of a par value of $10 each. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 2000 Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-P||ilippe bouchard.38854 163-1971 United Complex Ine.I,c ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 1er jour de décembre 1970, constituant en cor|Hiration: Irving L.Adcssky, 56, Place Heath, Hampstead, (lilies Poulin, 103, Asliton, Saint-Laurent, André Larivière, 3101, Édouard-Montpctit.Montréal, ct Robert Archambault, 200, Klgur, Ile-dcs-Socurs, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble ct dc construction, sous le nom dc « United Complex Inc.», avec un capital total de 840,000, divisé en 2,000 actions ordinaires dc S10 chacune ct 200 actions privilégiées dc SI 00 chacune.Le siège social dc la compagnie est à Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des instil ut ions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3S854 5304-1970 Gcne Venue (1970) ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu tie la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé tics lettres patentes, en date du 13c jour de novembre 1970, constituant en corporation: Charles Boldtic, analyste financier, 1743, rue Loyseuu, Saint-Bruno-dc-Montar-villc, Léonce Duchesne, 1937, Victoria, Laflèchc, Roger Duchesne, 92, rue Maple, et Bernard Imbeault, 257, rue St-Gcorgcs, ces deux derniers dc Moncton, ces trois tlerniers hommes d'affaires, pour les objets suivants: Faire affaires comme garagistes et faire le commerce d'accessoires ct parties d'automobiles ct véhicules de toutes sortes, sous le nom de « Gene Vcnnc (1970) ltée», avec un capital total tic 8250,000, divisé en 100,000 actions classe « A » de SI chacune, 100,000 actions classe « B » de SI chacune et en 500 actions privilégiées de S100 chacune.Le siège social de la compagnie est 965, boulevard Taschercau, Longucuil, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 4985-1970 Vie Tanny Québec Ltd.Vie Tanny Québec ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 31e jour de décembre 1970, autorisant la fusion des compagnies suivantes: « Vic-Tanny (Bonaventure) Ltd.», constituée par lettres The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-t.163-1971 United Complex Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 1st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies ami Cooperatives, incorporating: Irving L.Adcssky, 56 Heath Place, Hampstead, Gilles Poulin, 103 Asliton, Saint-Laurent, André Larivière 3101 Édouard-Monlpclit, Montreal, and Robert Archambault, 200 Elgar, Ilc-des-Socurs, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate and construction company, under the name of \"United Complex Inc.\", with a total capital stock of 8-10.000, divided into 2,000 common shares of 810 each and 200 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Coopérai ires.38854-0 5304-1970 Gene Venue (1970) liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing dale the I3tll day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Charles Boltluc, financial analyst, 1743 Loyseau Street, Saint-Bruno-dc-Montarville, Léonce Duchesne, 1937 Victoria, Laflèchc, Roger Duchesne.92 Maple Street, and Bernard Imbeault, 257 St-Gcorges Street, the latter two of Moncton, the latter three businessmen, for the following purposes: To carry on business as garage keepers and to deal in automobile and motor vehicle accessories and parts of all kinds, under the name of \"Gene Venue (1970) ltée\".with a capital stock of $250.000.divided into 100,000 class \"A\" shares of SI each, 100.000 class \"B\" shares of 81 each and into 500 preferred shares of S100 each.The head office of the company is at 965 Tasclicreau Boulevard, Longucuil, judicial district of Montreal.Ls-Phiuppe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 4985-1970 Vic Tanny Québec Ltd.Vic Tanny Québec liée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, dated the 31st day of December, 1970, have been issued by the Minister ol Financial Institutions, Companies and Cooperatives, authorizing the amalgamation of \"Vic Tanny (Bonaventure) Ltd.\", incorporated by letters patent tlatcd the 26th day of QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 patentes en date du 26e jour d'août 1968, * Vie Tanny (Côte St.Luc) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 7e jour de juin 1967, « Vie Tanny (Montreal) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 15e jour de juin 1967, « Vie Tanny (Montreal-Rockland) Ltd.», constituée par lettres patentes, en date du 2e jour dc février 1968, et « Vie Tanny (Québec City) Limited », constituée par letters patentes en date du 28e jour dc décembre 1967; toutes ces lettres patentes ont été émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, pour les objets suivants: Exploiter des gymnases et donner des leçons de culture physique, créer des activités de culture physique ct y participer, y compris des clubs de santé, des piscines ct bains turcs, sous le nom de « Vie Tanny Québec Ltd.\u2014Vie Tanny Québec ltée», avec un capital divisé en 40,000 actions ordinaires d'une valeur au pair ne devant pas excéder en valeur monétaire ou autre la somme de $100,000.Le siège social de la compagnie est 800, Carré Victoria, bureau 2204, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5776-70 Well-Nit Products Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il d accordé des lettres patentes, en date du 16e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Yoine Goldstein, 6505, Côte Saint-Luc, Robert Lefcort, 5400, Prince of Wales, et Leonard Flanz, 5750, avenue Trinity, tous trois avocats, de Montréal, pour les objets suivants: La confection et le commerce de tricots et matières textiles, dérivés du textiles et sous-produits de toutes sortes, sous le nom de « Well-Nit Products Inc.», avec un capital total de $40,000, divisé en 1,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de $10 chacune, 1,500 actions privilégiées classe « A » d'une valeur au pair de $10 chacune, et 1,500 actions privilégiées classe « B » d'une valeur au pair de $10 chacune.Le siège social de la compagnie est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 5573-1970 West End Youth Action Committee Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation sans capital-actions: Carolyn Alexander, épouse de Walter Alexander, 3844, Hampton, Margaret Hodgson, épouse de John D.Hodgson, 58, chemin Thurlow, toutes deux ménagères, Adèle 2001 August, 1968, \"Vic Tanny (Côte St.Luc) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 7th day of June, 1967, \"Vic Tanny (Montreal) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 15th clay of June, 1967, \"Vic Tanny (Montreal-Rockland) Ltd.\", incorporated by letters patent dated the 2nd day of February 1968 and \"Vic Tanny (Québec City) Limited\", incorporated by letters patent dated the 28th day of December, 1967, all such letters patent having been issued under the said Part I of the Companies Act, for the following purposes: To operate gymnasiums and to instruct in physical culture and to do and participate in all activities in connection with the aforesaid, including the operation of health clubs, swimming pools and steam baths, under the name of \"Vic Tanny Québec.Ltd.\u2014 Vic Tanny Québec ltée\", with a capital divided into 40,000 common shares without par value shall not exceed in money or moneys wortli an aggregate value of $100,000.The head office of the new company is at 800 Victoria Square, suite 2204, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Instituions, Companies and Cooperatives.38854-0 5776-70 Well-Nit Products Inc.Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Yoinc Goldstein, 6505 Côte St.Luc, Robert Lefcort, 5400 Prince of Wales, and Leonard Flanz, 5750 Trinity Avenue, all three lawyers, of Montreal, for the following purposes: To manufacture and deal in knitwear and textiles and textile products and by-products of all kinds, under the name of \"Well-Nit Products Inc.\", with a total capital stock of $40,000, divided into 1,000 common shares of a par value of S10 each, 1,500 class \"A\" preferred shares of a par value of $10 each and 1,500 class \"B\" preferred shares of a par value of $10 each.The head office of the company is at Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5573-1970 West End Youth Action Committee Inc.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate a corporation without share capital: Carolyn Alexander, wife of Walter Alexander, 3844 Hampton, Margaret Hodgson, wife of John D.Hodgson, 58 Thurlow Road, both housewives, Adèle Fetterly, bookkeeper, 2002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 Fetterly, comptable, épouse de Gordon Harold Fetterly, 4250, Westhill, et Trevor Smith, instituteur, 3821, Hampton, tous les quatre de Montréal, pour les objets suivants: Maintenir, exploiter et diriger un centre communautaire, sous le nom de « West End Youth Action Committee Inc.».Le montant auquel doit se limiter la valeur du revenu annuel sur les biens immobiliers que peut posséder ou détenir la corporation est de 825,000.Le siège social tie la corporation est au 3864, rue Girouard, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Puilippe Bouchard.38854 4495-1970 Westlock Realties Ltd.Les immeubles Westlock ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de décembre 1970, constituant en corporation: Ralph Lipper, 1550, avenue McGregor, Montréal, Robert Litvack, 590, avenue Stanstead, Mont-Royal, David Katznelson, 145, chemin Radcliffe, Montréal-Ouest, et Richard Evin, 201, Corot Rive, Ile-des-Soeurs, tous quatre avocats, pour les objets suivants: Établir et diriger une compagnie d'immeuble, de construction et de placement, sous le nom de « Westlock Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Westlock ltée», avec un capital total de 840,000, divisé en 4,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune et 36,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de SI chacune.Le siège social de la compagnie est 1, Place Ville-Marie, bureau 3635, Montréal, district judiciaire de Montréal: Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 5619-1970 wife of Gordon Harold Fetterly, 4250 Westhill, and Trevor Smith, school teacher, 3821 Hampton, all four of Montreal, for the following purposes: To maintain, operate and conduct a community centre, under the name of \"West End Youth Action Committee Inc.\".The amount to which the annual revenue from the immoveable property which may be owned or held by the corporation is to be limited, is 825,000.The head office of the corporation is at 3864 Girouard Street, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 4495-1970 Westlock Realties Ltd.Les immeubles Westlock ltée Notice is given that under Part I of the Companies Act, letters patent, bearing date the 21st day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Ralph Lippcr, 1550 McGregor Avenue, Montreal, Robert Litvack, 590 Stanstead Avenue, Mount Royal, David Katznelson, 145 Radcliffe Road, Montreal West, and Richard Evin, 201 Corot Rive, Ile-des-Soeurs, all four advocates, for the following purposes: To carry on the business of a real estate, construction and investment company, under the name of \"Westlock Realties Ltd.\u2014 Les immeubles Westlock ltée\", with a total capital stock of S40.000, divided into 4,000 common shares of the par value of SI each and 36,000 preferred shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 1 Place Ville-Marie, Suite 3635, Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 5619-1970 Lettres patentes supplémentaires Supplementary Letters Patent ' Acrodoo Industries Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Lui des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour de novembre 1970, à la compagnie « Aerodoo Holdings Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 10e jour de mars 1969, 1° changeant son nom en celui de « Aerodoo Industries Inc.» ; 2° étendant ses pouvoirs; 3° changeant 440,000 actions classe « A » sans valeur nominale en 440,000 actions ordinaires sans valeur nominale; 4° changeant et subdivisant 130,000 actions classe « B » sans valeur nominale en 650,000 actions Aerodoo Industries Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 25th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Aerodoo Holdings Ltd.\", incorporated by letters patent on March 10, 1969, 1.changing its name to that of \"Aerodoo Industries Inc.\"; 2.extending its powers; 3.changing 440,000 shares class \"A\" of no nominal value into 440,000 common shares of no nominal value; 4.changing and subdividing 130,000 shares class \"B\" of no nominal value into 650,000 common shares of no nominal value; 5.increasing its QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 2003 ordinaires sans valeur nominale; 5° augmentant son capital par la création de 1,910,000 actions ordinaires sans valeur nominale, pouvant être émises pour une considération totale de 82,000,000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 1077-69 B & C Tile Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16c jour dc décembre 1970, à la compagnie « B & C Tile Ltd.», subdivisant 395 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune en 39,500 actions privilégiées d'une valeur au pair dc SI chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 12706-57 Bric Holdings Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 7c jour dc décembre 1970, à la compagnie « Bric Holdings Ltd.», diminuant son capital de 82,000,100 à 81,928,100 par l'annulation de 7,200 actions privilégiées catégorie « A » de S10 chacune.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Piiilippe Bouchard.38854 4640-66 Consolidated Imperial Minerals Limited (No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, supplémentaires en date du 10c jour dc décembre 1970, à la compagnie « Imperial Minerals Limited (No personal liability) », constituée en corporation par lettres patentes datées du 15e jour de juillet 1953, 1° changeant son nom en celui de « Consolidated Imperial Minerals Limited » (No personal liability); 2° consolidant 5,000,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de SI chacune en 2,500,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S2 chacune; 3° convertissant 2,500,000 actions ordinaires d'une valeur au pair de S2 chacune en 2,500,000 actions ordinaires sans valeur au pair; 4° augmentant son capital par la création de 2,500,000 actions ordinaires sans valeur au pair- la considération globale pour l'émission desdites 5,000,000 actions ordinaires sans valeur au pair, émises et non émises ne devra pas excéder en montant ou valeur la somme de S5,000,000.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 15235-53 capital by the creation of 1,910,000 common shares of no nominal value, capable of being issued for a total sum of S2,000,000.Ls-Piiilippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 1077-69 B & C Tile Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Compagnies and Cooperatives to \"B & C Tile Ltd.\", subdivising 395 preferred shares of the par value of SI 00 each into 39,500 preferred shares of the par value of 81 each.Ls-Philippe BoucnARD, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 12706-57 Brie Holdings Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 7th day of December 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Brie Holdings Ltd.\", reducing its capital from S2.000.100 to 81,928,100 by the cancellation of 7,200 class \"A\" preferred shares of S10 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-o 4640-66 Consolidated Imperial Minerals Limited (No personal liability) Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act, supplementary letters patent dated the 10th day of December.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"Imperial Minerals Limited\" (No personal liability), incorporated by letters patent dated the 15th day of July, 1953, 1.changing its name into that of \"Consolidated Imperial Minerals Limited\" (No personal liability); 2.consolidating 5.000,000 common shares of the par value of SI each into 2,500,000 common shares of the par value of 82 each; 3.converting 2,500,000 common shares of the par value of 82 each into 2,500,000 common shares without par value; 4.increasing its capital by the creation of 2,500,000 common shares without par value; the aggregate consideration for the issue of tne said 5,000,000 common shares without par value, issued and unissued, shall not exceed in amount or value the sum of 85,000,000.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 15235-53 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, Vol.103, n' 9 Construfab inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 29e jour de décembre 1970, à la compagnie « Corporate Design Associates Ltd.\u2014 Les Associés en Dessin Corporatif liée ».constituée par lettres patentes en date du 14e jour dc septembre 1960, 1° changeant son nom en celui de « Construfab inc.»; 2° subdivisant 100 actions ordinaires d'une valeur au pair de S20 chacune en 10,000 actions sans valeur au pair; 3° subdivisant 180 actions privilégiées d'une valeur au pair de S100 chacune en 1,800 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune; 4° augmentant son capital par la création de 10,000 actions ordinaires sans valeur au pair ct 8,200 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune: 5° abrogeant les restrictions sur le transfert des actions et modifiant les droits et privilèges des actions privilégiées.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.3SS54-o 13864-60 Construfab inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 29th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Corporate Design Associates Ltd.\u2014 Les Associés en Dessin Corporatif ltée' , incorporated by letters patent on the 14th day of September, 1960, 1.changing its name to that of \"Construfab inc.\"; 2.subdividing 100 common shares of a par value of 820 each into 10,000 shares of no par value; 3.subdividing 180 preferred shares of a par value of 8100 each into 1,800 preferred shares of a par value of S10 each; 4.increasing its capital by the creation of 10,000 common shares with no par value and 8,200 preferred shares of a par value of 810 each; 5.withdraw the restrictions on the transfer of shares and to modify the rights and privileges of the preferred shares.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 13864-60 Entreprises G.Amyot inc.G.A m vol Enterprises Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies ct cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 31c jour de décembre 1970, à la compagnie « Entreprises CMA inc.\u2014 CMA Enterprises Inc.», constituée par lettres patentes en date du 6e jour de novembre 1970, changeant son nom en celui dc « Entreprises G.Amyot inc.\u2014 G.Amyot Enterprises Inc.».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 5189-70 Entreprises G.Amyot inc.G.Amyot Enterprises Inc.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 31st day of December.1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Entreprises CMA inc.\u2014 CMA Enterprises Inc.\", incorporated by letters patent dated 6th day of November, 1970, changing its name to that of \"Entreprises G.Amyot inc.\u2014 G.Amyot Enterprises Inc.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 5189-70 Handal Jewellery & Precious Gems Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu dc la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 4c jour de décembre 1970, à la compagnie « C & H Precious Stone Ltd.», constituée par lettres patentes en date du 5e jour d'août 1970, changeant son nom en celui de « Handal Jewellery & Precious Gems Ltd.».Le-sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854 3394-70 Handal Jewellery & Precious Gems Ltd.Notice is given that, under Fart I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 4th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"C & H Precious Stone Ltd.\", incorporated by letters patent dated 5th day of August 1970, changing its name to that of \"Handal Jewellery & Precious Gems Ltd.\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, .Companies and Cooperatives.38854-0 3394-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2005 Jest Investments Co.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 11c jour de décembre 1970, à la compagnie « Jest Investments Co.Ltd.», diminuant son capital de S1,915,000 à 81,900,000 par l'annulation de 150 actions privilégiées d'une valeur au pair de 8100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Lb-Piiilippe Bouchard.38854 17034-59 Jest Investments Co.Ltd.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 11th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Jest Investments Co.Ltd.\", reducing its capital from 81,915,000 to 81,900,000 by the cancellation of 150 preferred shares of the par value of 8100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854-0 17034-59 Mal.m.- Marine Agency Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie tic lu Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16e jour de décembre 1970, à la compagnie « Québec Terminais (1969) Ltd.», constituée par lettres patentes en date du lie jour d'avril 1969, changeant son nom en celui de ' Malone Marine Agency Limited ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-q 1660-69 Malone Marine.Agency Limited Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Québec Terminals (1969) Ltd.\", incorporated by letters patent on the 11th day of April, 1969, changing its name to that of \"Malone Marine Agency Limited\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 1660-69 Mobilier de Bureau et d'Hôpital de Québec inc.Mobilier de Bureau et d'Hôpital dc Québec inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date tlu 30e jour de décembre 1970, à la compagnie « L'Ëchange dc Meubles inc.», constituée par lettres patentes en date du 21e jour tie janvier 1958, 1 ° changeant son nom en celui de « Mobilier dc Bureau ct d'Hôpital de Québec inc.» ; 2° augmentant son capital de 810,000 à 840,000 pur la création dc 3,000 actions privilégiées d'une valeur au pair de 810 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-q 10240-58 Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 30th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies nntl Cooperatives to « L'Échange de Meubles inc.», incorporated by letters patent tlatetl 21st day of January, 1958, 1.changing its name to that of \"Mobilier tic Bureau et d'Hôpital de Québec inc.\"; 2.increasing its capital from 810,000 to 840,000 by the creation of 3,000 preferred shares of a par value of 810 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial hislitutions.Companies and Cooperatives.38854 10240-58 Termino Corporation Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie dc la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en tlatc du 16e jour de décembre 1970, ù la compagnie « Three Rivers Shipping Company, Limited», constituée par lettres patentes en date du 10e jour tic janvier 1955, changeant son nom en celui de « Termino Corporation ».Le sous-minislre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-0 13237-54 Termino Corporation Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of December, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Three Rivers Shipping Company, Limited\", incorporated by letters patent on the 10th day of January, 1955, changing its name to that of \"Termino Corporation\".Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 13237-54 2006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n' 9 Trois-Rivières Auto Electric Ltd.Trois-Rivières Auto Électrique ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 16c jour dc novembre 1970, à la compagnie « Trois-Rivières Auto Electric Ltd.\u2014 Trois-Rivières Auto Électrique ltée», 1° réduisant son capital de SI 15,000 à $40,000 par l'annulation dc 750 actions privilégiées dc S100 chacune; 2° augmentant son capital dc S40.000 à 5200,000 par la création dc 1,600 actions privilégiées dc S100 chacune.Le sous-minislre des institutions financières, compagnies cl coopératives, Ls-Philippe Bouchard.38854-q 8880-49 Trois-Rivières AutoJElcctric Ltd.Trois-Rivières Auto Électrique ltée Notice is given that, under Part I of the Companies Act, supplementary letters patent, bearing date the 16th day of November, 1970, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"Trois-Rivières Auto Electric Ltd.\u2014 Trois-Rivières Auto Electrique ltée\", 1.reducing its capital from S115.000 to 840,000 by the annulment of 750 preferred shares of S100 each; 2.increasing its capital from 840,000 to S200.000 by the creation of 1,600 preferred shares of S100 each.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.38854 8S80-49 Ministère des institutions financières, compagnies ct cooperatives Assurances L'Equitable, Compagnie d'Assurances Générales The Equitable General Insurance Company Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company», compagnie provinciale, dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec « L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company », compagnie fédérale, dont le siège social est situé à Montréal, province de Québec, en vertu d'un contrat dc réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 31 décembre 1970, et lequel contrat de réassurance a pris effet le 1er janvier 1971 ; Attendu que « L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The_ Equitable General Insurance Company », compagnie fédérale, est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company », compagnie provinciale, s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; Én conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company », compagnie provinciale, sont annulés à compter du 1er janvier 1971.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 2 janvier 1971.Pour le Ministre, des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 38778-8-2-0 Roger-A.Camaraire.Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance L'Équitable, Compagnie d'Assurance Générales The Equitable General Insurance Company Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company\", provincial company, whose head office is situated in Montreal, Province of Québec, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company\", federal company, whose head office is situated in Montreal, Province of Québec, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 31st of December 1970, with effect with the 1st of January 1971; Whereas \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company\", federal company, is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company\", provincial company, has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"L'Équitable, Compagnie d'Assurances Générales \u2014 The Equitable General Insurance Company\", provincial company, are cancelled as from the 1st of January 1971.Given at the office of the Insurance Branch, Department of financial institutions, companies and cooperatives, the 2nd of January 1971.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 38778-8-2-0 Superintendent of Insurance. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2007 Ventes pour taxes Sales for Taxes Cité de la Pointe-aux-Trembles Avis est par les présentes donné par le soussigné, Guy Vanier, grenier de la cité de la Pointe-aux-Trembles, que les immeubles ci-dessous désignés, seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville, 11953 est, rue Notre-Dame, Pointe-'aux-Trembles, Québec, LUNDI, le QUINZIEME jour du mois de MARS 1971, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales générales et scolaires, des intérêts et des frais encourus, à moins que ces taxes, frais et intérêts ne soient réglés avant cette date à l'Hôtel de Ville, 11953 est, rue Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.City of Pointe-aux-Trembles Notice is hereby given by the undersigned, Guy Vanier, City Clerk of the city of Pointe-aux-Trembles, that the immoveable properties hereinafter described, will be sold by public auction at the City Hall, 11953 Notre-Dame Street East, Pointe-aux-Trembles, Québec, on MONDAY, the FIFTEENTH day of MARCH, 1971, at TEN o'clock a.m., for the payment of general municipal taxes, school taxes and interest, as given below, and the costs which may be subsequently incurred, unless before that date, the said taxes, interest and costs have been paid at the City Hall, 11953 Notre-Dame Street East, Pointe-aux-Trembles.Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 21 Monico Inc., 3155, 36e Avenue, Ville St-Michel.27 Denis Quintal, 11,770 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .66 Charles-E.Bousquet, 1448, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles .83 Lamothe Automobile Ltée, 11,905 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.99 Gilles Beauséjour & J.-E.St-Laurent, 598, 3e Avenue, Pointe-aux-Trembles.105 Ernest Messier, 11,764 Prince-Albert, Pointe-aux-Trembles .123 Cyprien Dion, 1811, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles.148 André Kingsley, 11,530 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles .149 Mme F.-P.Lepage, 11,536 Lagauehetière, Pointe- aux-Trembles .159 Léo Miousse, 858, 3e Avenue, Pointe-aux-Trembles 163 Léon Gagnon, 11,690 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .172 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .173 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.188 Placements Ville Marie Ltée.198 Paul-H.Zannis, 5734 avenue Coolbrook, Montréal.209 L.Katezanski & B.H.Goldstein, 6513 Borden, Côte St-Luc, Montréal.216 C.Baillargeon & Frères Ltée, 40 Des Frênes, Pointe-aux-Trembles .273 C.Proulx, 11,885 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.279 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles.280 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles .281 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles .284 Lucien Prud'Homme, 537 Préfontaine, Montréal.291 Mme Joseph Dufresne, 3157 Jean Brillant, Côte des Neiges, Montréal.304 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .390 Paul Bissonnette, 833, 3e Avenue, Pointe-aux-Trembles .99-P.105-7, 104-5-P.101-43 à-to 47.121-82-83.100-24-25-P.101-101-108-30-31.93 175-P.à-to 177 100-75.93 102 103-P.93-103-P.S 100-106 à-to 108-P.\" 100-102-P.109 263.109 264.93-213.214.100-217-218.109-401 à-to 404, 121-318 à-to 321 93-244 à-to 246.121-443-P.444.93-369-370-368-P.93-372-373-374-P.93-375-376-376-P.93-379-P.380-P.100-350.109-602-P.121-685-686.21.42 S 646.87 8 68.25 1,748.12 1,722.40 375.76 80.30 295.22 211.60 620.60 S 428.00 608.70 425.60 548.58 426.40 67.88 528.93 202.05 176.48 303.13 31.41 187.76 239.33 311.74 663.26 24.38 579.88 571.47 509.93 164.66 47.48 22.23 260.60 485.20 165.20 134.80 157.20 28.20 28.20 251.89 108.65 988.76 428.00 425.60 426.40 13.60 13.27 100.40 ¦2008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103- année, n' 9 Numéro do compte Account number Nom et adresse Namo and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1068 Munie.taxes TaxeB scol.1008 School taxes Taxes munie.1069 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 395 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .\u2022128 Fernand Giroux, 11,938 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.448 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .479 Oreste Basile, 786, 1ère Avenue, Pointe-aux-Trembles.492 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.494 Camille Boutin, 11952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .498 Dame Ronald Tétroault, 1258,1ère Avenue, Pointe-aux-Tromblcs.512-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.528 Camille Boutin, 11052 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .533 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .540 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles .541 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- Trembles.551-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.504 W.Stemart Milne, 1284, 2e Avenue, Pointe-aux-Trembles.607 Crédit Immobilier Inc., 1260.8e Avenue, Pointe-aux-Trombles.008 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Tromblcs.003 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .737-06 Marc-Aimé Guérin, 6861, 42e Avenue, Rosemont, Montréal.737-07 Marc-Aimé Guérin, 6801, 42e Avenue, Rosemont, Montréal.740 Crédit Immobilier Inc., 1260.8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .741 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Tremblos.798 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .844 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Tromblos.848 Charles-E.Bousquet, 1448, 6e Avenue, Pointe-oux-Trembles.892 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.939 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.987 Maurice Morin, 1855, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles.999 Normand Dubé, 1639, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles .1004 J.-G.Denis, 11,365 Bois de Boulogne, Montréal .1020 Victor McMullen & Uxor, 1847,6e Avenue, Pointeaux-Trembles.1022 Philippe Champagne & Uxor, 1859, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles.1024-05 Roger Bergeron, 1931, 5e Avenue, Pointe-aux-Trembles.1104 Paul-Emile Cyr, 9166, 57e Avenue.Rivière des Prairies, Montréal.121-1223.$438.45 121-877-P.-878.28.08 121-947-1007.16.37 93-92-P.93-P.78.70 93-229-230.466.02 93-233 à-to 235.521.92 93-366.$262.43 $224.00 243.41 93-869-P.870____ 26.18 93-272-271.484.63 93-260-259 .484.63 93-391-390.499.25 93-389-388 .484.61 93-908-P.907 ____ 27.72 93-423-424 .283.64 93-946-948-P.41.19 93-947.93-976-P.-977- 978-P.38.50 100-374-376.9.34 100-376-377.18.32 100-732-P.79.46 100-733-734-P.100-763-P.-764- 765-P.332.42 100-788-P., 789.790-P.172.41 101-51-62.124.36 101-744-P.746.746-P.100-825-P.826.824-P.168.45 101-769-P.770.771-P.58.99 101-461.33.67 6.80 36.34 101-658-P., 559-P.63.03 101-564-P.564-P.184.94 101-679-P., 680-P.154.76 101-681-P., 682-P 27.90 101-692-P.693-P.156.60 101-971,108-620.769.97 469.60 767.96 $ 82.12 29.8IÏ 405.20 430.00 221.00 50.41 424.00 422.00 438.80 422.00 73.83 174.40 43.90 43.90 82.95 29.03 42.30 72.17 72.17 27.20 70.51 70,61 6.80 134.40 127.20 127.60 469.60 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2009 Numéro do compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie, taxes Taxes sool.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 1169 Chnrles-E.Bousquet, 1448, 6e Avenue, Pointe-aux-Trembles.108-621.! 1211 Claude Sanschagrinotai., 2130 FleuryE., Montreal 109-736.736-1'.1237 It.& Thomas Louis Laforest, 765, 7e Avenue, Pointe-aux-Trembles.109-273 à-to 281.1238 R.& Thomas Louis Laforest, 756, 7e Avenue, Poin- te-aux-Trembles .109-282 à-to 293.1243 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .109-306, 307, 308.1244 Katezanski, M.L.& Goldstein, B.11., 5513 Bordon, Côte St-Luc, Montréal.109-406 à-to 412.1265 Donato Belviso, 1837, 7e Avenue, Pointe-aux-Trembles.109-776-P.776.8139.20 1311 M.Katezanski & B.II.Goldstein, 5513 Borden, Côte StrLuc, Montreal.121-322.1313 M.Katezanski & B.H.Goldstein, 6513 Borden, Côte St-Luc.Montréal.121-323-P., 323-P.à-to 330.1314 Metal & Ore Co.Ltd., 1440 Towers Street, Room 202, Montréal.'.121-331 à-to 346.1343 Chnrles-E.Bousquet, 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Trembles.121-1218.1386 Y von Daoust, 4520 Joan Rivard St-Léonard\u201e Port Maurice, Montréal.P.Q.121-364 à-to 366.1390 Marcel Ricard.771 Vaudreuil.Repentigny, Cté Assomption.121-371,372.1512 Patrick McLaughlin, 1942, 9c Avenue, Pointe-aux-Trembles .121-869-P.870.1534 Yves Sauvageau, 743,9e Avenue, Pointe-aux-Trembles.121-279,280.1556 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.121-1208.i .\u2022>;\">\" Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.121-1209.1660 Gilles Desjardins, 1671, 9e Avenue, Pointe-aux-Trembles-_.121-1213.1573 Joan François Rioux, 1847, 9e Avenue, Pointe-aux-Trembles.121-890,891.1675 Eugène Lemire, 1871, 9e Avenue, Pointe-aux-Trem- bles.121-894,896.1666 Camille Boutin, 11952, Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.175-484.1657 Camille Boutin, 11952, Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.176-483.1676 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.175-167-P.à-to 170-P.1688-01 Crédit Immobilier Inc.1260, 8o Avenue, Pointe-aux-Trembles.175-317-P.à-to 323-P., 326 à-to 328-P.1690 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8o Avenue, Pointe-aux-Trembles .175-604.1700 Entreprise Rex Inc., 215.St-Jacques, Montréal.175-183,184 .47.66 $ 69.12 1704 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- nux-Trembles.175-261.262.1707 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Trembles .175-494 .1707-04 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Trembles .175-367 .1733-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Trembles.175-167-P., 324-P.96.87 \u2022 67.97 1765 J.Darius Martineau, 985, 8e Avenue, Fabreville, Cté Laval.45-140.141.0.60 1.90 1858 James Beaudry, 16, 42e Avenue, Pointe-aux-Trembles.206-1149,1160.1863 Serge Bouchard, 656, 24e Avenue, app.14, Pointe-aux-Trembles.210-3.1860 Claude Delorme, 8001 Bloomfield, app.2, Montréal 206-1153 à-to 1166 1899 Gilles Chartier, 16,162 Bellerivo, Pointe-aux-Trembles.234-8.1910-01 Dame Gilles Talbot, 16170 Bellerive, Pointe-aux- Tremblee.234-7-P.199.28 96.23 338\t20\t$127\t20 8\t30\t\t 714\t62\t\t 1,239\t62\t\t 186\t13\t63\t87 234\t73\t106\t66 181\t26\t128\t80 24\t00\t9\t01 298\t66\t110\t92 251\t02\t\t 387\t88\t113\t60 124\t18\t15\t66 210\t60\t120\tso 190\t84\t27\t47 18\t47\t\t 937\t38\t178\t40 9\t63\t10\t00 218\t93\t11\t68 255\t73\t\t 10\t88\t\t 2,421\t26\t767\t20 104\tOS\t42\t80 363\t32\t86\t27 \t\t192\t44 81\t23\t308\t57 223\t08\t66\t36 315\t03\t72\t17 8\t85\t\t \t\t56\t61 14\t53\t10\t00 23\t60\t\t 266\t38\t\t 22\t99\t\t 370\t68\t184\t80 344\t26\t218\t80 2010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 87 février 1971, 103' année, n\" 9 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.taxes Taxes bcoI.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 1955 Hôtel Bout de L'Ile Inc., a/s W.McDonald, 16,403, Bureau, Pointe-aux-Trembles.1971 Entreprises Gauvin Inc., 16,360 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.1982 J.Kramer & C.Grekin, 9200, boulevard St-Lnurent, Montréal.1983 Murray Lapin, 615, Dorchester O., suite C30, Montréal.2082 Claude Robillard, 13,136 Aragon, Villa Pierrefond, P.Q.2095 Hôtel Richelieu Ltée, 15,920, Notre-Dame, Pointeaux-Trembles .2119 Entreprises Gauvin Inc., 16,360, Notre-Dame, aux-Trembles.2123 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.2137 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 396, Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.2142 George Spencer Finnie, 14,001, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .'.2159 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.2162 Fernand Aubin, 14,485, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .2176 Frédéric Lefebvre, 14,751, Notre-Dame, Pointe- aux-Trembles .2177 David Myer Lerner, 5915, McDonald Avenue, Montréal.2177-01 David Myer Lerner, 5915, McDonald Avenue, Montréal.2178-01 N.Levine & Son Inc.& al.4855, Isabella, Montréal 2178-02 N.Levine & Son Inc.& al.4855, Isabella, Montréal 2180 Nivel Realties Inc., 4855, Isabella, Montréal.2209 Entreprises Rex Inc., n/s Lajoie & Gélinas & al., 215, St-Jacques O.Montréal, P.Q.2220 Léo Gauthier, 15,990, Delphis Delorme, Pointe-aux-Trembles .2232 Yvon Girard, 539, rue Hughes, Quartier Fabreville, Ville Laval, P.Q.2268 Monico Inc., 3156, 36e Avenue, Cité St-Michel.2278 David Myer Lerner, 5915, McDonald, Montréal.2278-01 David Myer Lerner.5915, McDonald, Montréal.2280 Wister Corp- a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2283-01 Marcel Bastien, 12,878, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .2292 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2294 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2344-01 N.Levine & Son Inc., et al 4855, Isabella, Montréal 2344-02 N.Levino & Son Inc., et al 4855 Isabella, Montréal.2344-03 N.Levine & Son Inc.et al.4855 Isabella, Montréal 2344-04 N.Levine & Son Inc.et al.4855 Isabella, Montréal 2344-05 N.Levine & Son Inc.et al.4855 Isabella, Montréal 2349 Jean-Paul Matteau, 13,906, Forsyth, Pointe-aux-.Trembles.2358 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2361 Corps, des Pères Capucins de Québec, 4373 Avenue Esplanade, Montréal.2363 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2367 Dame Omer Goyette, a/s J.Geoffrion, 620, Cathcart, Suite 720, Montréal.2373 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.2396 Lionel Laehance, 10,154, Bt-Vital, Montréal-Nord.235-48.235-457,450, 433.203-P., 204-P.204-P.229-1.213, 133-P., 231-P.127-P.235-461-460.205-4.208-46.209-P.213-P.214-158 .216-43-44-45.216-575, 576, 577, 578.216-577-P., 578-P.218-1-P.200-20-P., 21-P.224-P., 225-P.229-P.232-P.234-P.233-1,5.216-504 à-to 567.216-566, 567.202-78.Bâtisse sur terre 205.$2,045.57 $3,333.70 306.12 32.18 1,948.17 1.197.80 981.71 240.30 187.20 262.02 508.07 1,413.13 2,088.80 18.39 356.11 1,322.86 1,707.10 375.27 266.81 31.58 378.24 302.80 109.30 68.26 $49.84 829.74 28.50 11.01 32 34 3,528.92 9,837.01 1,761.36 249.59 78.72 48.13 43.51 15.42 103.60 31.28 370.82 56.41 1,777.77 2,297.60 308.00 1,148.80 206-1228.\t15.89 206-1283, 1284,\t 1285.\t37.95 218-15, 16, 17.\t32.34 217-67, 58.\t16.94 217-65, 66.\t16.18 217-38, 39.\t17.72 217-36, 37.\t16.94 228-208, 209\t22.34 206-1075 à-to 1076\t\u2022 93.03 206-1246.\t13.62 206-1300 à-to 1302\t40.45 206-898, 899\t93.03 206-1251, 1252,\t 1304.\t40.46 209-110 à-to 107 .\t945.07 23.20 662.40 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 2011 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.tnves Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie, taxes Taxes scol.1969 School taxes 2400 Holland Lnuzon, 14,130, Dorchester, Pointe-aux-Trembles.2421 Lauréat Mnrtineau, 14 Place Dufort, Repentigny.2422 Lauréat Martineau, 14, Place Dufort, Repentigny.2439-07 N.Levine & Son Inc.et al.4855, Isabella, Montréal 2439-08 N.Levine & Son Inc.et al.4855, Isabella, Montréal 2442 Mme Gérard Boisvert, 1800, 42e Avenue, Pointeaux-Trembles .2444 Miquel Gagnon, 10,525, Iberville, Montréal.2446 Dame Orner Goyette a/s J.Geoffrion, 620, Cath- cart, Suite 720, Montréal.2611-01 Abcab Holdings Ltd., a/s G.S.Finnie, 14,001, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.2543 Mme Henri Pigeon, 2550, rue Hameury, Duvernay, Cité de Laval, P.Q.2575-01 Abcab Holdings Ltd., a/s G.S.Finnie, 14,001, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.2594 Gérard Chartrand et al.10,738, André Jobin, Montréal .2004 Joseph Urbain, 15, rue St-Charlcs, Ste-Thêrèse de Blainville, P.Q.2619 Pères Capucins du Québec, 3650, de la Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.2631 Roland Bruneau, 3154, Dickson, Montréal.2634 Roland Bruneau, 3164, Dickson, Montréal.2635 ¦ Roland Bruneau, 3154, Dickson, Montréal.2637 Société M.E.N.Inc.15,949.Sherbrooke.2703 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-01 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-02 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-03 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-04 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-05 Pères Capucins du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2703-06 Pères CapucinB du Québec, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles.2720 Roland Bruneau, 3154 Dickson, Montréal.2810 Manoir Epiphanie Inc., Epiphanie, P.Q.2816 Roland Nadeau, 3473.40e Avenue, Pat.2824 Rosario Séguin, 1622 Bourbonnière, Montréal.2843 Roland Comtois, 4075, 40e Avenue, Pat.2846 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.2036 Guy Perrier, 4083, 41e Avenue, Pointe-aux-Trembles .2959 Hervé Hamel, 3706, 42e Avenue, Pointe-aux-Trembles.2977 Mme Muni Ségal, 5197, Earnscliff, Montréal.2988-01 Marcel Bastien, 12,878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .2990-01 Marcel Bastien, 12, 878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .2996 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 396 Mayor, Suite 1011, Montréal.2999 Wister Corporation, 395 Mayor, Suite 1011, Mont- réal.3000 Ernest Denis, 1271 Gentilly, Ville Jacques-Cartier.3048 Mme Gérard Boisvert, 1800, 42e Avenue, Pointeaux-Trembles.3048-01 Mme Gérard Boisvert, 1800, 43e Avenue, Pointeaux-Trembles.210-132, 131.212, 596-P., 597-1*.212-597-P., 598 .217-52, 53.217-50, 61.206-757 à-to 760.863.83 206-763.206-768, 769.209-226, 225.216-213.6.63 209-361, 360.212-1362.216-221.6.21 207-P.228-323-P.à-to 330-P.228-385, 386-P.228381-P.à-to 384-P.232-17, 16.208-583, 582.208-580, 581.208-579,578.208-577,576.208-517, 516.208-515, 514.208-513-P., 512 P.511-P.228-387-P.à-to 390, 425 à to 8501.88 353.90 8230.80 202.22 16.00 16.55 16.94 117.87 43.74 89.20 93.03 91.94 $9.63 7.70 8.00 111.60 835.82 733.20 1.45 7.31 7.60 3,940.26 1,152.53 124.74 124.80 75.07 78.00 608.85 23.70 23.70 23.70 24.16 23.70 23.70 7.18 432.205-1013 à-to 1015 205-628 à-to 630.205-762-P.763-P.764-P.à-to 767.205-1049 à-to 1050\t166.94\t184.21\t89.71 96.88 131.57 235.47 144.31\t93.20 53.20 113.20 154.80 108.80 205-1055.\t\t\t20.37\t13.27 205-1102,1103.\t\t\t44.92\t104.80 206-330, 331.206-609 à-to 611.\t114.77\t\t184.84 170.09\t146.80 63.60 206-869 à-to 873\t28.02\t20.28\t22.46\t4.40 206-877 à-to 880.\t22.03\t15.93\t66.70\t12.80 206-1013, 1014.\t\t\t82.24\t 206-1021, 1022.206-1023.\t\t\t81.70 40.68\t 206-771,772,\t\t\t83.96\t32.00 \t19.10\t4.45\t83.96\t 2012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103- année, n\" 9 Numéro de compte Account riumber Nom et adresse Name and address No du oadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1068 Munie, taxes Taxes scol.1068 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 3050-01 Marcel Bastien.12,878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.3050-03 Marcel Bastien, 12,878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.3056-10 Jacques Huard Synd.6334 Cairns, Ville D'Anjou.3058 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395 Mayor, Suite 1011, Montréal.3076 Léonido Stopponi, 1074, 43e Avenue, Pointe-aux-Trembles.3081 John Ed.Chs.Shannon, 55 Somerville Avenue, Westmount, P.Q.3145 Claudette Langford, 1043, 43e Avenue, Pointe-aux-Trembles .3151 Marcel Bastien, 12,878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles .3153-01 Marcel Bastien, 12,878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.3162 Mme Joseph Sartell, 6 CypresB St.Weston, Ontario.3163 Mme Joseph Sartell, 5 Cypress St.Weston, Ontario.3163-01 Mme Joseph Sartell, 5 Cypress St.Weston, Ontario.3163-02 Mme Joseph Sartell, 6 Cypress St.Weston, Ontario.3163-03 Mme Joseph Sartell, 5 Cypress St.Weston, Ontario.3103-04 Mme Joseph Sartell, 5 CypressSt.Weston, Ontario.3163-05 Mme Joseph Sartell, 5 Cypress St.Weston, Ontario.3163-06 Mme Joseph Sartell, 5 CypressSt.Weston, Ontario, 3186 Mme Henri Pigeon, 2550 Hameury, Duvemay, Cité de Laval, P.Q.3200 The Wister Corp., 395 Mayor St.Suite 1011.Montréal.3212 The Wister Corp.306 Mayor St.Suite 1011, Montréal.3212-01 The Wister Corp.395 Mayor St.Suite 1011, Montréal.3214 The Wister Corp., 395 Mayor St.Suite 1011, Montréal.3214-01\tThe Wister Corp.\t\t395 Mayor St.\t\tSuite\t1011, 3214-02\tThe Wister Corp.,\t\t395 Mayor St.\t\tSuite\t1011, 3214-03\tWister Corp., a/s Pomerlian & Neamtan, 396\t\t\t\t\t 3214-04\tWiBter Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3214-05\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3214-06\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3222\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3226\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet.\tSuite\t1011, 3226-01\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3226-02\tWister Corp.,\t396\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, 3226-03\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet.\tSuite\t1011, 3226-04\tWister Corp.,\t395\tMayor\tStreet,\tSuite\t1011, Montréal.3230 3231 3234 3249 Dame Guy Bouchard Wister Coi Montréal 395 Mayor Street, Suite 1011, Wister Corp.395 Mayor Street.Suite 1011.Montréal.Wister Corp., 396 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.206-921, 924, 927 à-to 929.206-921-P.922.923.206-924.927-P.206-1037, 1038.206-1060.1081.206-1072.1073.206-1095 à-to 1097 206-981 à-to 985.206-970 à-to 972.206-576-P.677-P., 678-P.206-501 à-to 675.206-663,664.206-505, 568.206-567,668.206-669, 570.206-671,672.206-573, 674, 576.206-291.206-1232.1233.206-1256.1266, 1267.206-1268, 1259, 1257.206-1261, 1262, 1263.206-1264,1265.206-1266, 1267.206-1268, 1269.206-1270, 1271.206-1272, 1273.206-1274, 1276.206-1471, 147-P.206-1474, 1476.206-1476, 1477.206-1478.1470.206-1480, 1481.206-1482.1483.1484.206-1489.206-1400.206-1639 à-to 1641 206-1287, 1288.S 13.60 16.33 16.10 150.94 11.11 S 3.25 11.80 10.00 6.44 f 38.40 266.23 76.66 83.96 163.26 83.96 219.49 18.66 271.85 27.49 34.20 34.20 34.26 34.26 34.26 34.26 51.37 18.17 23.63 35.64 23.63 35.64 23.63 23.63 23.63 23.63 23.63 23.63 16.26 23.63 23.63 23.63 23.63 35.64 12.01 12.01 38.04 23.63 S 63.20 18.96 116.00 3.60 24.00 18.96 177.75 10.00 6.40 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1071, Vol.103, No.9 2013 Numéro de compte Account number Nom cl.adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1068 Munie, taxes Taxes sool.1068 School taxes Taxes munie.1069 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 3249-01 Wister Corp., 396 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3240-02 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3240-03 Wister Corp., 395 Mayor Street.Suite 1011, Montréal.3249-04 Wister Corp., 395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3249-05 Wister Corp.396 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3259 Wister Corp., 395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3201 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3261-01 Wister Corp., 305 Mayor Street, 8uite 1011, Montréal.3261-02 Wister Corp., 306 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3261-03 Wister Corp., 305 Mayor 8treet, Suite 1011, Montréal.3261-04 Wister Corp., 305 Mayor Street, 8uite 1011, Montréal.3261-05 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3261-06 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3261-07 Wister Corp., 305 Mayor 8treet.Suite 1011, Montréal.3264 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3204-01 Wister Corp., 305 Mayor Street.Suite 1011, Montréal.3264-02 Wister Corp., 305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.3264-03 Wister Corp.306 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-04 Wister Corp.305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-05 Wister Corp.305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-00 Wister Corp.305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-07 Wister Corp.305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-08 Wister Corp.395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3264-09 Wister Corp.305 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3204-10 Wister Corp.395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal .3268 Mme Vve Lionel Huard, a/s Irène Lessard, 136 boulevard St-Elzéar, Vimont, Cté Laval.3274 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Roubbo-lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3281 J.Y.Neveu et al., 521, lOème Avenue, Lavul des Rapides, P.Q.3280-02 Jean-Paul Matteau, 13,906 Forsyth, Pointe-aux-Trembles .3283 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3660 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3660 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3660 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.206-1280, 1200.206-1291, 1202.206-1203, 1204.206-1205, 1206.206-1207, 1208.206-1500-P.206-1501-P., 1502.1503.206-1504.1606.206-1500, 1607.206-1608, 1500.206-1610, 1511.206-1612, 1513.206-1514.1516.206-1516, 1617, 1518.206-1564, 1665, 1566.206-1667, 1668.206-1560, 1670.206-1571, 1672.206-1673, 1674.206-1675.1676.206-1577, 1678.206-1670, 1580.206-1681, 1582.206-1683, 1684.206-1686, 1686.206-1688 à-to 1600 207-P.208-500 à-to 601-P.208-403-P.à-to 407-P.13,300.60 208-617, 618.208-610, 620.208-621, 622.208-623, 024.208-626, 620.S23.03 23.63 23.63 23.63 23.63 13.48 33.51 23.63 23.63 23.63 23.63 23.63 23.63 36.64 38.04 25.23 25.23 26.23 26.23 26.23 25.23 26.23 26.23 26.23 26.23 32.00 36.49 $110.74 3,684.68 3,170.20 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 $18.80 2014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108' année, n° 9 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie, taxes Taxes scol.1969 School taxes 3282-05 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3282-06 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-07 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-08 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3283-10 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3284 Corp.Frs.Capucins de Québec, 4373 Esplanade, Montréal.3284-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 4373 Esplanade, Montréal.3307 J.P.Matteau, 13,906 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.3313 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-05 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-06 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-07 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-08 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3313-10 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3318 Adjutor Harvey, 1025, 48ème Avenue, Pointe-aux-Trembles .3353 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3354 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3365-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-05 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-06 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3660 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-07 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-08 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3365-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3355-10 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.3303 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395 Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.3403 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3660 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-627, 628.208-620, 630.208-031, 032.208-033, 034.208-635, 636.208-637, 638, 639.208-678, 679, 639.208-680, 681, 682.208-457 1.208-685, 686.208-587, 588.208-589, 690.208-691, 692.208-593, 594.208-695, 500.208-597, 508.208-599, 000.208-601, 002.208-603, 004.208-605, 006, 607.208-135 à-to 138.208-552, 653.208-554, 655.208-556, 557.208-558, 559.208-560, 561.208-562, 603.208-564, 565.208-566, 567.208-508, 569.208-570, 571.208-572, 573.208-658, 059.208-060, 661.208-265 à-to 267.208-510-P.à-to 521-P.218.60 18.60 18.50 18.60 18.60 27.83 16.86 24.40 63.26 S16.20 18.60 18.60 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.60 27.84 328.04 109.13 18.52 18.52 18.62 18.52 18.52 18.52 18.52 18.62 18.52 18.62 18.62 19.93 20.76 331.02 8.00 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2015 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre Taxes et subdivisions munie.1068 No.of cadastre Munie, and subdivisions taxes Taxes Taxes scol.munie.1968 1969 School Munie, taxes taxes Taxes scol.1969 School taxes 3403-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3060 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-522,523.$0.44 3403-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-624,525.0.44 3403-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3060 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-626,527.6.44 3403-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-628,529 .0.44 3403-05 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-530, 531.0.44 3403-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-632,533.6.44 3403-07 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-534,535 .0.44 3403-08 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-530,637.0.44 3403-09 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière.Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-638,539 .0.44 3403-10 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière.Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-640,541.0.44 3403-11 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-053,054.107.41 3404 Pères Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe- aux-Trembles, P.O.208-055,656.189.81 3405 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3G50 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-P.1,303.70 3407 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.200-P.355.08 3418-01 W.E.Geo.Finnie, 14001 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.209-170,177.182.80 3421 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame.Pointeaux-Trembles.200-202 à-to 281.177.81 $371.22 3421-01 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.200-204,206.177.80 3421-02 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles .200-200, 207.177.80 3421-03 Abcab Holdings Ltd.14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.200-268,260.177.80 3421-04 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.\u2022.200-270,271.177.80 3421-05 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.200-272,273.177.80 3421-00 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.200-274,275.177.80 3421-07 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles .200-270, 277.177.80 3421-08 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles.200-278,270.177.80 3421-00 Abcab Holdings Ltd., 14,001 Notre-Dame, Pointeaux-Trembles .200-280, 281.177.80 3453 J.-P.Matteau, 13,000 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.200-361,352.28.46 3453-01 J.-P.Matteau, 13,000 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.209-363,354.28.45 3485 Eloi Dufour, 1034, 61e Avenue, Pointe-aux-Trembles.210-172 à-to 174.$140.31 300.61 208.81 3500 Mme Alexis Lefort, 4255 De Repentigny, Montréal 211-5-P., 106-P.472.44 38.3' 3505 Mme Jenn-Clnude Cudotte, 3601, 52e Avenue, Pointe-nux-Tremblcs.211-082 à-to 084.108.01 00.41 3029-01 Jean-Paul Matteau, 13,900 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.211-581,682 .212.31 3660 Clément Mussie, 1933, 53e Avenue, Pointe-aux-Trembles.211-1001 à-to 1003 351.12 50.0 3701 Aimé Lecours, 1808, 64e Avenue, Pointe-aux-Trembles.211-1035,1036.166.63 98.61 3731 Arthur Jette, 141 rue Lavoisier, Lavai des Rapides, P.Q.212-610-P.611.612-P.262.46 14.81 3732 Arthur Jette, 141 rue Lavoisier, Laval des Rapides, P.Q.212-612-P., 513.256.07 14.» 3737 Clément Maasie, 1033 , 53o Avenue, Pointe-aux-Trembles.212,640,641.310.21 200.01 2010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n' 9 Numéro rie compte Account number Nom et adresse Nnmo and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 3907 François Côté, 25, 57e Avenue, Pointe-aux-Trembles.213-22 1 23 35 1.3954 JeanSéKUin,21,58eAvenue,Pointc-aux-Trembles.213-P.4021 Fernand Aubin, 14,485 Notre-Dame, Pointe-aux- Tremblea.214-160-P.4082 Claudia Dufrcsne a/s Mme Eloi Forest, Providence, Notre-Dame, Assomption.216-324.4002 Wister Corp., 395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.216-340.4118 F.Sinai Lefebvre, 14,751 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.216-46.4122 Wister Corp., 395 Mayor Street, Suite 1011, Montréal.216-93.4153 David E.Myer Lerner, 5915 McDonald Avenue, Montréal.216-668.4164 David E.Myer Lerner, 5916 McDonald Avenue, Montréal.216-669 à-to 672.4164-01 David E.Myer Lerner, 5915 McDonald Avenue, Montréal.210-671,672.4169 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.216-404.4169 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 306 Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.216-406.4178 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.216-504.4181 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.216-507.4187 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-1 à-to 20- 4187-01 N.Levino & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-6,7.4187-02 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-8,0.4187-03 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-10, 11, 12____ 4187-04 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabelle, Montréal 218-10, 20.4187-05 N.Levine &Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-21, 22.4187-00 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella.Montréal 218-23, 24.4187-07 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-25, 26.4187-08 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-36,37.4187-09 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-38, 30.4187-10 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-40,41.4187-11 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-42, 43.4187-12 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-44, 45.4187-16 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-46, 47.4187-16 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 218-48,40.4187-17 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréul 218-50,51,52____ 4187-18 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montréal 217-139, 140.4187-10 N.Levine* Son Inc.et al., 4855 Isnbella, Montréal 217-141, 142, 143.4187-20 N.Levine & Son Inc.ct al., 4855 Isabella, Montrénl 217-144, 146.4187-21 N.Levine & Son Inc.et al., 4856 Isabella, Montréal 217-223, 224.4187-22 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-225, 226.4187-23 N.Lovino & Son Inc.et al., 4856 Isabella, Montréal 217-227, 228.4187-24 N.Levine & Son Inc.etal.,4855 Isabella, Montréal 217-220, 230.4187-26 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-231.232.4187-26 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-233, 234-P.4187-27 N.Levine & Son Inc.et ai.4855 Isabella.Montréal 217-242-P., 243.4187-28 N.Levine & Son Inc.et \u201e/., -1855 Isabella, Montréul 217-244, 245.4187-20 N.Levine & Son Inc.et ni., 4855 Isabella, Montréul 217-322,323.4187-30 N.Levino & Son Inc.et al., 4855 Isubellu, Montrénl 217-324,325.4187-31 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isubellu, Montrénl 217-326.327.4187-32 N.Levine & Son Inc.otai.,4855 Isnbella, Montréul 217-328, 320.4187-33 N.Levine à Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montrénl 217-330,331.4187-34 N.Levine & Son Inc.etai., 4855 Isabella, Montréal 217-332, 333.4187-35 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montrénl 217-334, 335.4187-30 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 227-330, 377.4187-37 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-338, 330.4187-38 N.Levine & Son Inc.etai.,4855 Isabella, Montréal 217-340, 341.4187-30 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-342, 343, 344.4187-40 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-420,421.4187-41 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-422,423.4187-42 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montréul 217-424, 426.4187-43 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montréal 217-426, 427.4187-44 N.Levine & Son Ine.et al, 4855 Isabella, Montrénl 217-428,420.4187-45 N.Levine & Son Inc.et al., 4855 Isabella, Montréal 217-430, 431.4187-46 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montréal 217-132,433.4187-47 N.Levine & Son Inc.et ai., 4855 Isabella, Montréal 217-434, 436.$160.28 337.46 $ 208.80 $3.02 $3.20 46.20 3.08 3.08 11.93 6.16 6.94 28.50 28.60 3.08 3.08 3.08 3.08 23.49 23.49 23.49 36.20 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 13.47 18.48 8.63 20.02 13.47 13.47 23.88 33.88 33.88 33.88 20.17 30.41 33.88 6.94 0.94 0.94 6.94 6.94 0.94 0.94 6.94 0.94 0.94 10.02 0.94 6.94 6.94 6.94 0.94 6.94 U.94 6.94 10.40 3.20 18.00 8.63 70.15 6.64 6.64 6.64 1,007.01 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2017 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions TaxeB munie.1968 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 4187-18 4187-49 4187-51 4187-52 4187-53 4187-54 4188 4188-01 4188-02 4188-03 4188-04 4188-05 4188-0G 4188-07 4188-08 4188-09 4188-10 4188-11 4188-12 4188-13 4188-14 4188-15 4188-10 4188-17 4188-18 4188-19 4188-20 4188-21 4188-22 41SS-23 4188-24 4188-25 4188-20 4189 4189-01 4189-02 4180-03 4189-04 4180-05 4189-00 4180-07 4189-08 4189-09 4189-10 4191 4191-01 4191-02 4191-03 4191-04 4191-06 4191-00 4191-07 4191-08 4191-09 4191-10 4191-11 4191-12 4191-13 4191-14 4193 4193-01 4193-02 4193-03 4193-04 4193-05 Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine & Son lue & SonInc & SonInc & Son Inc, & Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.etai.etai.et al.et al.etai.etai.etai.etai.etai., etai., etai.etai., etai.etai., etai., etai., et al., et al., et al., etai., etai., etai, etai., etai., et al., et al., etai., etai., etai., etai., etai., et al., etai., etai, 4855 Isabella 4855 Isabella 4855 Isabella 4855 Isabella 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella.4865 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isubellu, 4855 Isnbella, 4855 Isabella, 4855 Isnbella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isnbelln, 4855 Isnbelln, 4855 Isnbelln, 4855 Isnbella, 4855 Isubellu, 4855 Isabella, Montréal Montréal , Montréal Montréal Montrénl Montréal Montréal Montrénl Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montrénl Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal' Montréal Montrénl Montréal Montréal N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine & Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.et al etai etai et al.etai etai etai et al, et al, etai, etai et al.etai et al.etai etai etai etai etai etai etai et al.etai etai etai etai 4855 Isnbella, 4865 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, Montréal Montréal Montrénl Montréal Montréal Montréal Montréul Montrénl Montréal Montréul Montréal 4855 Isnbelln, 4855 Isabella, 4865 Isnbella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, 4855 Isabella, Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montrénl Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal N.Levine & Son Inc.et al, N.Levine & Son Inc.et al, N.Levine & Son Inc.et al, N.Levine & Son Inc.et al, N.Levine & Son Inc.et al, 4855 Isabella, Montréal 4855 Isabella, Montréal 4855 Isabella, Montréal 4855 Isabella, Montréal 4865 Isabella, Montréal 217-436, 437.217-438, 430.217-483.484____ 217-485,486.217-487,488.217-489,400.217-24, 25.217-26, 27.217-28, 29.217-30, 31, 32____ 217-61, 62.217-63, 64.217-05, 00.217-07, 08.217-115, 110.217-117, 118.217-119, 120.217-121, 122.217-123, 124.217-125, 120.217-127, 128.217-129, 130.217-131, 132.217-133, 134.217-135, 130, 137.217-199, 200.217-201, 202.217-203, 204.217-205, 200.217-207, 208.217-200, 210.217-218, 210.217-220, 221.217-31 à-to 33, 34-P., 35-P., 36 à-to 153,154-P., 155ù-to 160, 161-P.102 à-to 172, 173-P.217-300, 301.217-302, 303.217-304, 305.217-300, 307.217-308, 300.217-310, 311.217-312, 313.217-314, 316.217-310, 317.217-318, 310, 320.217-181-P., 182 à-to 180, 100-P.300, 307.217-308, 300.217-400, 401.217-402, 403.217-404, 405.217-400, 407.217-408, 400.217-410, 411.217-412, 413.217-414, 415.217-410,417,418.217-474, 476.217-476, 477.217-478, 479.217-480,481.\".217-101 à-to 200, 210-P., 7 8.217-0, 10.217-11, 12.217-13, 14.217-16, 16.217-42, 43.S 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04 6.16 13.80 S 13.86 13.80 25.79 13.80 13.80 13.80 13.80 13.86 13.80 13.86 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 20.41 13.80 23.88 33.88 33.88 33.88 19.26 31.19 33.88 14.93 6.94 6.94 6.94 0.04 0.94 0.94 0.94 0.94 6.94 0.94 10.17 6.94 0.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 10.02 6.94 6.94 6.94 7.31 28.11 28.11 28.11 28.11 39.65 16.40 3,366.11 929.04 616.12 2018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.37 fôoricr 1071, 103' année, n\" O Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1068 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 4193-00 4193-07 4193-08 4193-09 4193-10 4193-11 4193-12 4193-13 4193-14 4193-15 4193-10 4193-17 4193-18 4193-19 4193-20 4193-21 4193-22 4193-23 4193-24 4193-25 4194-20 4194 N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.4194-01 4194-02 4194-03 4194-04 4194-05 4194-00 4194-07 4194-08 4194-09 4194-10 4196 4196-01 4196-02 4190-03 4190-04 4190-05 4196-0G 4196-08 4190-09 4196-10 4190-11 4190-12 4196-13 4196-14 4198 4199 4268 4345 4373 4373-01 4373-02 4502 4528 4602 4603 4018 Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine Levine & Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.etai.et al.etai.etai.etai.et al.et al.etai.etai.etai.et al.et al.etai.et al.etai.ct al.et al.etai.etai.etai.et al.etai.4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, .4855 Isabella, , 4855 Isabella, .4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, ,4855 Isnbella, , 4855 Isnbelln, ,4855 Isnbelln, , 4855 Isabella, ,4855 Isabella, , 4855 Isabella, ,4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4S55 Isnbelln, , 4855 Isabella, Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal Montrénl Montréul Montréal Montréul Montréal Montréal Montréal Montrénl Montréal Montrénl Montréal Montreal Montrénl Montréul Montréal Montréal Montréal N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine N.Levine & Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Sou Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc.& Son Inc, & Son Inc.etai.et al.etai.etai.et al.etai.et al.etai.etai.etai.etai.et al.et al.etai.et al.et al.etai.etai.etai.etai.etai.et al.etai.etai.etai.4855 Isabella, ,4855 Isubellu, 4855 Isabella, ,4S55 Isabella, 4855 Isabella, ,4855 Isabella, i 4855 Isnbella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isabella, ,4855 Isabella, ,4S55 Isnbelln, ,4855 Isnbella, , 4855 Isubellu, ,4855 Isabella, , 4855 Isabella, , 4855 Isnbelln, , 4855 Isabella, ,4855 Isabella, , 4855 Isabella, ,4855 Isabella, , 4855 Isabella, Montreal Montreal Montrénl Montréal Montrénl Montréal Montrénl Montréul Montrénl Montrénl Montréal Montrénl Montréal Montréal Montréal Montréal Montréul Montréul Montrénl Montréul Montréul Montréal Montrénl Montréal Montrénl N.Levine & Son Inc.et ni., 4855 Isabella, Montréul R.O.Auxtin Uxor, 20 Karol Drive, Framinghnm, Mass.Roland Bruneau.3154 Dickson, Montréal.Roland Bruneau, 3154 Dickson, Montréal.Roland Bruneau, 3154 Dickson, Montréal.Roland Bruneau, 3154 Dickson, Montréal.M.D.Q.Ltd., 15,850Sherbrooke, l'ointe-aux-Trem-bles.Jacques Hébert, 22, 96e Avenue, Pointe-aux-Trembles .Hôtel Bout de l'Ile Inc., 16,403 Bureau, Pointeaux-Trembles .Hôtel Bout de L'Ile Inc.10.403 Bureau, Pointeaux-Trembles .Mlle Gertrude Desiardins, 4083 Côte Ste-Catheri-ne, Montréal, P.Q.217-44,45.217-40, 47, 48____ 217-81, 82.217-83, 84.217-85.80.217-87, 88.217-89, 90.217-91, 92.217-93, 94.217-95, 90.217-97, 98.217-99, 100.217-101, 102, 103.217-102, 103.217-104, 105.217-100, 107.217-108, 109.217-170, 171.217-172, 173.217-181, 182.217-183, 184.217-218-P.219 a-.to221,222-l\\, 201, 202.217-203, 204.217-205, 200.217-207, 208.217-209,270.217-271,272.217-273,274.217-275, 270.217-277,278.217-279, 280.217-281, 282, 283.217-223 à-to 233, 234-P., 360, 301 217-302, 363.217-304,305.217-360,307.217-308,369.217-370, 371.217-372, 373.217-376, 377.217-378,370.217-380, 381, 382.217-457,458.217-459,460.217-401,402.217-403,464.217-242-P., 243 n- to 491.218-1.2-P.à-to 11-P., 12, 13, 14-P., 16, 10, 17-P.18 ù-to 52, 53-P.227-217,216.228-392.228-424, 423.228-422, 421.228-420,419,418.Bâtisse sur-Building on 232-19 P.235-301-P, 300-P.510.10 $10.00 $15.40 23.49 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.64 14.04 14.64 14.64 14.64 21.96 13.86 24.64 36.03 35.03 36.03 18.87 33.40 24.04 6.65 6.55 6.65 6.55 6.55 6.55 6.65 6.55 6.65 6.55 0.63 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 8.85 6.77 5.77 5.77 6.77 $227.28 343.41 4,272.76 235-47.235-47., 235-27 à-to 24.15.40 7.70 15.40 15.40 23.10 0.71 305.09 11.40 908.03 10.00 8.00 56.00 131.89 228.11 207.38 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2019 Numéro\t\tNo du cadastre\tTaxes\tTaxes\tTaxes\tTaxes do compte\tNom et adresse\tet subdivisions\tmunie.\tscol.\tmunie.\tscol.\t\t\t1968\t1968\t1969\t1969 Account\tName and address\tNo.of cadastre\tMunie.\tSchool\tMunie.\tSchool number\t\tand subdivisions\ttaxes\ttaxes\ttaxes\ttaxes 4651 David Myers Lerner, 6915 avenue McDonald, 216-562 à-to 563, Montréal.673,574.4709-02 Mme J.L.Paquette, 6667 De La Roche, Montréal 200-389, 390.4714 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395 Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.206-1588à-to 1590 4729 Eugene Dinelle, 2402 Ste-Catherine E.Montréal.212-1241.$4.03 $4.00 4789 Dame Georges Lesage, 5147 Jeanne D'Arc, Mtl.206-558,559.4790 Wister Corp.n/s Pomerlian & Nenmtan, 395 Mayor, Suite 1011.Montréal, P.Q.206-1492.4795 Corp.Frs.Mineurs Capucins du Québec, 3050 Dc La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-610, 015.4795-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins du Québec, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-014, 013.4795-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 De Ln Rousselière.Pointe-aux-Trembles.P.Q.208-612, 611.4795-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3650 Do La Rousselière, Pointe-uux-Trembles.P.Q.208-010, 609.4795-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3060 De Ln Rousselière.Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-550, 549.4795-05 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-548, 547.4795-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De Ln Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-540, 5-15.4795-07 Corp.Frs.Mineurs Cupucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.20S-544, 543.4830 Dame Jean Beugle, 11,715 Tolhurst.Montréal____ 206-453.13.43 4838 Wister Corp.a/s Pomerlian & Neamtan, 395 Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.206-1560 à-to 1502 4839 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3G50 De La Rousse- lière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-070, 009.4839-01 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-008, 007.4839-02 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De Lu Rousselière.l'ointe-aux-Trembles, P.Q.20S-0G0, 005.4839-03 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-004, 003.4839-04 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-051, 050.4839-06 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 Do La Rousselière, Pointe-uux-Trembles, P.Q.208-649, 6-18.4839-00 Corp.Frs.Mineurs Capucins.3050 Do La Rousselière, Pointe-uux-Trembles, P.Q.208-047, 646.4839-07 Corp.Frs.Mineurs Capucins, 3050 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, P.Q.208-645.644.4911 Edouard Gagné, 25.67e Avenue, Pointe-aux-Trembles.205-1111,1112.18.02 16.40 4926 Abe P.Starr, 7515 East Luc, Côte St-Luc, Montrénl 206-53,54.4028 Wister Corp.u/s Pomerlian & Neamtan, 395 Mayor, Suite 1011, Montréal, P.Q.206-56.4939 Louise Lachapelle, 2034 Cartier, app.3.Montréal.109-14.5004 Philippe Fraser, 29 De Normandie, Pointe-aux-Trembles.199-10.6005 Philippe Fraser, 20 De Normandio, Pointe-aux-Trembles.100-11, 12.36.70 5010 Stékal Inv.Corp.a/s H.Mnrgolese, 1660 do Mai- 200-1'., 200 à-to sonneuve, Suite 800, Montréal.200-P.5019 Dame Gilles Rocheleau, 12,177 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.180-4-P., 180-5-P.5037 Mme Corine Roy.0504 St-Dominique, Montréal.185-24.138.05 5004 WisterCorp.395, Mayor, Suite 1011, Montrénl.197-P.5006 Wister Corp.395, Mayor, Suite 1011, Montréal.198-10, Il.5070 New Development Corp.a/s B.Small Co., 1010, Ste-Catherine O.,chemin 700, Montréal.200-P.5070-01 New Development Corp.a/s B.Small, Co., 1010, Ste-Catherine O., chemin 700, Montréal.200-P.5102 Gérard Poitras & Uxor, 11,800, Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles.184-38,30.115.00 74.40 5133 Jean-Paul Matteau Ltée, 13,000, Forsyth, Pointeaux-Trembles.185-71-P.5136 Jean-Paul Matteau Ltée, 13,006, Forsyth, Pointeaux-Trembles.185-70-P.5136-01 Jean-Paul Matteau, 13,006, Forsyth, Pointe-aux-Trembles.185-70-P.$01.04\t$112.81 40.10\t 48.50\t 3.80\t4.00 6.11\t 15.64\t 10.40\t 19.49\t 10.40\t 19.87\t 10.40\t 19.49\t 4.21\t 4.29\t 20.34\t11.20 48.60\t 19.49\t 19.49\t 19.49\t 19.87\t 19.49\t 19.49\t 4.21\t 4.29\t 33.33\t10.40 37.10\t21.80 18.03\t 23.98\t 50.35\t18.80 320.42\t218.00 3,184.25\t112.20 435.08\t32.40 230.79\t 10,779.43\t 140.11\t 3,334.89\t 3.427.82\t 244.22\t74.40 572.37\t367.60 664.67\t344.40 292.34\t172.80 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Numéro No du cudnstre Taxes Taxes Taxes Taxes de compte Nom et adresse et subdivisions munie.scol.munie.scol.1908 1968 1969 1969 Account Name and address No.of cadastre Munie.School Munie.School number and subdivisions taxes taxes taxes taxes 5130-02 Jean-Paul Matteau, 13,900, Forsyth, Pointe-aux-Trembles.5137 Dame Pierre Rodrigue, 10,384, Boul.St-Michel, Montréal-Nord, P.Q.5143 \u2022 Jean-Paul Matteuu Ltée, 13,900, Forsyth, Pointeaux-Trembles .5143-02 Jean-Paul Matteau & Uxor, 13, 900, Forsyth, Pointe-aux-Trembles.5150 Canadian National Rly, P.O.Box 8100, Montréal 5150-01 Canadiun National Rly, P.O.Box 8100, Montréid 5150-02 Canadian National Rly, P.O.Box, 8100, Montréid 5155 René Fontaine, 13,171, Victoria, Pointe-aux-Trembles.5155-01 René Fontaine, 13,171, Victoria, Pointe-aux-Trembles .5158 Wister Corp., 395, Mayor, Suite 1011, Montréal.5100 C.Pouliot, E.L.Lemieux, 1301, 17e Avenue, Pointe-aux-Trembles .5193 Lucien L'Abbé, 305, De Normandie, Pointe-aux-Trembles .5203 Louis Grenier, 425, De Normandie, Pointe-aux-Trembles.5254 Denis Baily, 12,322, Parent, Pointe-aux-Trembles.5208 Anselme Daigle, 3021, Sherbrooke, Montréal.5317 Saul Harry Miller, 1094, St-V'iateur O., Montréal.5318 Herman Daigneault et al.1039, Orléans, Montréid 5350 Dame Giovanni Cianci, 12,534, Parent, Pointe-aux-Trembles .5357 Dame Giovanni Cianci, 12,534, Parent, Pointe-aux-Trembles .5429 C.Baillargeon & Frères Ltée, 40 Des Frênes, Poin-tes-aux-Trembles.5547 Georges Lechasseur, 12,205, Ste-Catherine, Pointeaux-Trembles .5553 J.P.Nadeau, 12,311, Ste-Catherine, Pointe-aux-Trembles .5560 J.-Emile Leblanc, 12,415, Ste-Catherine, Pointeaux-Trembles .5629 Aug.E.Hormidas Dubuc; 2301, Régent, Montréal 5032-27 Eli Brown et al., 772, Wilder, Outremont, Montréal 6634 G.Albert Gauthier, 4523 De Laroche, Montréid- 5000 Roland Proulx, 12,133, Ontario, Pointe-aux-Trembles.5676 Dame Alfred Deschamps, 12,241, Ontario, Pointeaux-Trembles .5693 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5697 Lucien Labbé, 12,254, Gratton, Pointe-aux-Trembles .6709 Bernard Bourbonnais, 12,334, Gratton, Pointe-aux-Trembles.5710 Dame Roger Perron, 12,350, Gratton, Pointe-aux-Trembles .6712 Paul Chartier, 12,384, Gratton, Pointe-aux-Trembles.5717 Lionel Caron, 12,117, Gratton, Pointe-aux-Trembles .6734 Ernest Painchaud, 12,291, Gratton, Pointe-aux-Trembles .6740 André Baillargeon, 1780, Carré Duclaux, Québec.6741 Laurier Gatien, 5300, Delanaudière, Montréal.6747 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6752 Jean-Paul Beauchamp, 12,400, Sherbrooke, Pointeaux-Trembles .185-70-P., 71-P.$574.32 1307.00 185-73-P.542.18 323.60 185-82-P.19.91 185-82-P.100.34 16.00 191-P.195-P., 190-P.302.36 195-P.312.48 190-P.430.60 199-91.02, 110, 117.272.02 130.80 199-91, 02, 110, 117.67.76 202-02.12.00 185-77-P.592.23 338.57 185-109.323.61 185-200.60.38 182-134, 135 .204.73 188.82 177-149-1'., 150-P.168.99 184-188.101.47 12.32 184-20S à-to 211 .372.90 125.20 177-241,242-P.$347.63 $180.80 357.07 186.80 177-242-P., 243-P.220.03 183.40 227.00 182.40 184-318.319, 320- P.354.66 357.51 180-318,319,320-P.433.95 172.00 182-394,395,390-P.370 à-to 377.133.79 184-448,440.263.03 150.00 199-444 à-to 440 .40.32 25.60 190-9.3.29 177-486-P.24.66 8.28 177-518-P., 519-P.191.93 136.00 181-515,516.73.41 180-400.21.57 181-567.508-P.118.28 182-548-P., 649, 550.416.98 184-560, 67, 68-P.406.77 140.40 184-570-P., 71, 72 481.06 144.00 177-577-P., 578-P.180.63 136.00 182-553-P., 554 .320.87 161.60 184-602-P., 603, 604 .411.24 162.00 420.13 152.00 184-038,630.131.76 180-038 3 .71.67 182-603, 4, 6, 6, 7, 8,0.803.00 73.20 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2021 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1908 Munie, taxes Tuxes scol.1908 School taxes Taxes Taxes munie.scol.1969 1969 Munie.School taxes taxes 5756 Jacques Joyal, 1014, 1ère Avenue, Pointe-aux-Trembles.5771 Jean-Paul Beauchamp, 12,400, Sherbrooke, Pointe- aux-Trembles.5772 Jean-Paul Beauchamp, 12,400, Sherbrooke, Pointe- aux-Trembles .5785 Ben Cohen et al., 591.Davaar, Montréal.5797 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5799-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e ave, Pointe-aux-Trembles .5805 Curé Paroisse Ste-Anne, a/s Foyer Charité, 3500, 32e Avenue, Pointo-uux-Trembles.5810 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenuo, Pointeaux-Trembles .5810-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5810-02 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue.Pointeaux-Trembles.5812 Crédit Immobilier Inc., 1200, Se Avenue, Pointeaux-Trembles.5827 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Tremble\",.5841 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.5842 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.5843 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.5S44-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5852 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .5852-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5852-02 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5852-03 Crédit Immobilier Inc., 12G0, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5852-04 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.5852-05 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5853 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe nux-Tremblcs.5866 liai monde Costan/o, 2652 Vauquelin, Montréal.6904-02 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.6905-04 Lave Auto Pointe-nux-Trembles Ltée, 1295 St-Jeun-Buptiste, Pointe-aux-Trembles, P.Q.5905-05 Camille Boutin, 11,052 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .6905-00 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .5905-07 Camille Boutin, 11,052 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .6905-08 Camille Boutin, 11,062 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .5905-09 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .6913 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5017 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6919 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .184-035-P., 030 .$343.27 182-030, 1, 2, 3.4, 6,6.184-662.3, 4, 6, 6, 7, 8, 184-702, 3, 4, 5, 6, 184-710- P.200-P.181-696.181-698,099.199-582, 3, 4.177-730, 1,2,3, 4.5.177-732.733.177-734,735.177-755.766.181- 714.181-757, 758.177-792, 3, 4, 6, 6, 177-797,798,818 177-819,820.181-776, 77, 78.181-779.\u2022177-822.823.177-824,825.177-826, 827.177-828.820.177-830, 831.177-832, 833.181-821,22, 23,24 108-442, 443.174-100, 2.174-100, 6, 4.174-100, 6, 5.174-100, 6, 6.174-100, 6, 7.176-372,4.176-372, 3.176-100.176-115.176-130, 1,2,3,4.370.24 $ 364.36 $ 110.80 604.78 121.60 803.10 233.20 3,238.61 1,210.64 0.86 19.06 162.84 10.11 10.11 10.14 31.76 20.10 78.18 21.00 30.62 9.86 21.23 21.23 21.25 21.76 23.61 22.36 42.60 32.66 392.04 762.01 760.76 748.00 206.62 1,160.43 107.76 107.76 638.72 12.60 24.60 23.20 87.10 40.60 25.90 100.10 33.18 30.20 12.60 100.08 54.60 6.10 78.40 161.60 160.40 160.20 46.20 113.20 167.20 33.18 33.18 165.00 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108- année, «° 9 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadustre et subdivisions No.of cadastre nnd subdivisions Taxes munie.1908 Munie.taxes Taxes scol.1908 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 5921 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8c Avenue, Pointe- aux-Trembles .5922 La Tourelle Inc., a/s Robert Beaudry, 210 Crémazie O., Montréal.5929 Robert Sareault, 3459 boulevard St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles.6933 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6933-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-nux-Tremblcs.5933-02 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5933-03 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5933-04 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5033-05 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6937 La Plaza St-Jcan-Bnptiste, 6420 Victoria, Montrénl, chnmbro 6.5951-02 Mme Pierre Joly, 1020, 12e Avenue, Pointe-aux-Trembles .6953 La Tourelle Inc.a/s Robert Beaudry, 210 Crémazie O., Montréid.6956 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-nux-Trcmbles.6958 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6960 Frank Cih, 12,056 Prince-Arthur.Pointe-aux- Trembles .6961 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .5963 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8o Avenue, Pointe-nux-Trcmble8.6966 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8o Avenue, Pointeaux-Trembles .5908 La Tourelle Inc.n/s Robert Beuudry.210 Crémazie O-, Montréal.6970 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe-nux-Trembles.6973-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6973-02 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6073-03 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .5973-04 John McCarthy, 21 boulevard Lévesque, Repentigny .5073-07 Les Entreprises Immobilières Cardinales Ltée, 110 Crémazie O., 10e étage, Montrénl.5073-09 Les Entreprises Immobilières Cardinales Ltée, 110 Crémazie O., 10e étage, Montréid.5996 Gilbert Chevrier, 837, 12e Avenue, Pointe-aux-Trembles .6998 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6003 Léonard Forest, 053, 12e Avenue, Pointe-aux-Trembles .6013 Mme Antonio Biondo, 12,110 Dorchester, Pointeaux-Trembles .176-167, 168, 169.170-170, 171, 172.176-261, 202, 203.170-318 a-to 324, 170-337 a-to 343 170-320, 321 .176-322, 323.324.176-337, 338.176-330, 340.176-341, 342, 343.176-48-40.170-410 1.176-212 ii to 215.176-253-P.176-258.176-274 a-to 277.170-289-P., 290.170-307 a-to 310.170-331 A-to 334, 346 a-to 348 350 à-to 353.176-192, 211, 210.170-344, 349.170-287.292, 311, 325, 330, 278, 297, 310, 335, 354.181-702, 780, 825, 826, 828.820-P.835.177-44, 46, 778, 799,821,44,45, 40.152.152 a-to213.176-423.176-422.176-838.177-76.76.177-166.177-163.164.177-284 a-to 286-P.$103.32 881.29 175.90 103.38 05.95 112.18 54.44 78.19 $323.25 323.25 299.30 00.92 00.92 91.38 60.92 00.94 91.43 245.75 47.82 80.97 198.65 21.40 34.53 99.97 49.17 112.61 438.26 153.61 170.18 398.10 3.05 247.80 13.47 39.47 48.57 162.79 258.00 460.07 $99.54 00.54 160.80 130.87 14.70 30.10 110.05 25.00 44.10 127.40 05.30 130.87 304.98 300.04 891.71 19.91 268.00 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 27, 1971, Vol.103, No.9 2023 Numéro No du cadastre Taxes Taxes Taxes Taxes de compte Nom et adresse et subdivisions munie.scol.munie.scol.19G8 1908 1909 1909 Account Nnme and addresB No.of cadastre Munie.School Munie.School number nnd subdivisions taxes taxes taxes taxes 0054-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- .aux-Trembles.177-838-P.0001 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-00 Crédit Immobilier Inc.1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-07 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-08 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-00 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0001-10 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.0003 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0093 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue.Pointeaux-Trembles .0100 Entreprises Rex Inc.a/s Lajoie Gélinas et al., 215 St-Jacques, Montréal.0120 Crédit Immobilier Inc., 12G0, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0124 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0188 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6101 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8o Avenue, Pointeaux-Trembles .0102 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .6103 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .6104 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles .0104-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .0104-02 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.0201 Gérard Robert, 1 lOSte-Ktionne, L'Assomption.0253 Paul Lucien Colette, 1S62, 14e Avenue, Pointe-uux-Trembles.180-390-P., 400, 401-P.0255 Lucien Deschnmps, 2180 Désormeaux, Montréal.180-031 1,631 2-P.0201-01 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.180-484-P., 518-P.0320 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.180-510-P.517, (180-647).0302 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181,276.¦ 0305 Maurice Lévesque, 1240, 15o Avenue, Pointe-aux Trembles.181-280,281.6377 André Bastien, 1400, 15o Avenue, Pointe-aux-Trembles.181-397,398.0380 Roger Ouellette, 87 Du Crochet, Laval des Rapides.181-401.0402 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-847.0402-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8o Avenue, Pointeaux-Trembles.181-776.0-103-02 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-702, 703.0400 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-708,700.0407 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, I'ointe- nux-Trembles.181-710,711,712.6408 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-763.764.0410 Crédit Immobilier Inc., 1260.8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-760 à-to 774.«13.70 177-7G6à-to 777.\t17.48\t$160.26 177-791.817.834, 835.\t23.68\t234.76 177-768.769, 834, 835.\t17.48\t 177-770, 771\t17.48\t 177-772, 773\t17.46\t 177-774, 776\t17.46\t 177-776, 777\t17.46\t 177-44-P., 45-P.\t30.72\t68.85 177-354 .\t77.80\t01.01 177-535.\t85.03\t 177-005-P., 666.\t163.43\t 177-780, 700\t17.48\t22.40 177-000-P., 601.\t163.43\t 177-806.\t8.73\t11.20 177-800,807 ,\t17.46\t26.64 177-808.800\t17.47\t26.64 177-810 à-to 816.\t17.48\t02.00 177-812, 813\t17.48\t 177-814,815, 816.180-14, 16.\t26.22 174.18\t160.20 $00.03 $11.20 137.40 244.11 201.07 70.22 68.00 60.81 80.54 466.80 5.22 20.68 20.68 30.62 20.82 61.11 106.80 0.05 66.80 22.40 11.20 343.00 10.78 26.60 26.60 30.20 26.60 80.60 2024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103e année, 7i° 9 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.1968 Munie.taxes Taxes scol.1968 School taxes Taxes munie.1969 Munie.taxes Taxes scol.1969 School taxes 6411 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.181-827.6446 Cyprien Dion, 1811, 15e Avenue, Pointe-aux-Trembles.181-543,544.6455 Camille Boutin, 11952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.\u2022.181-846.0450 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.181-845.6500 Dame Marcel Thorroux, 1950, 10e Avenue, Pointe- 181-022-P., 23-182-562-P., 03-P.S 12.00 S 18.25 377.48 185.60 0533\tCrédit Immobilier Inc.,\t1260,\t8e Avenue, Pointe- \taux-Trembles.\t\t 6535\tCrédit Immobilier Inc.,\t1260,\t8e Avenue, Pointe- \t\t\t 6572-02 Bertrand Blain, 1913, 16e Avenue, Pointe-aux-Trembles.182-580-P., 581-P.6572-09 Gérard Amesse, 1955, 10e Avenue, Pointe-aux-Trembles.182-587-P., 588-P.0573 Jean-Paul Beauchamp, 12,400 Sherbrooke, Pointeaux-Trembles.182-037 à-to 039, 640-P.6574 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles .182-818.6575-02 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.182-816,2,2.6576 Jean-Paul Beauchamp, 12,400 Sherbrooke, Pointeaux-Trembles.182-049-P.0570-01 Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux- aux-Trembfes.182-817.6582 Les Entreprises Itex Inc., 215 St-Jacques, Suite 508, Montréal.182-112,113,114.6632 Jean-Paul Beauchamp, 12,400 Sherbrooke, Pointeaux-Trembles.182-650, 061, 159.89 088.60 52.99 52.99 42.50 222.67 736.33 158.62 377.40 15.71 106.40 535.20 90.80 19.91 19.91 21.70 343.60 06.30 8.48 1,488.20 1,226.80 161.91 33.00 0634 6636 6636-01 6655 0690 6718 0746 6762 6764 6799 6814 6815 6822 6823 6824 6832 6837 6838 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles.G.Albert Gauthier Ltée, 4523 De Laroche.Montréal .Jean Bade, 1039, 17e Avenue, Pointe-aux-Trembles Raoul Bouchard, 804, 18e Avenue, Pointe-aux-Trembles .LaUrent Albert, 1022, 18e Avenue, Pointe-aux-Trembles.Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.Mme Vve Albert Bond, 503, 18e Avenue, Pointeaux-Trembles.Maurice Beaudet, 1415, 18e Avenue, Pointe-aux-Trembles .Roger Warren, 1911, 19e Avenue, Pointe-aux-Trembles .Rock Entreprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, Ville Mont-Royal, P.Q.Jean-Paul Beauchamp, 12,400 Sherbrooke, Pointe- Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.Camille Boutin, 11,952 Lagauehetière, Pointe-aux-Trembles .Mme Camille Thibault, 6504 St- Dominique, Montréal.Jean-Paul Matteau & Uxor, 13,906 Forsyth, Jean-Paul Matteau & Uxor, 13,906 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.l \t\t\t83.57\t44.80 \t\t\t59.50\t66.30 \t\t\t706.29\t343.60 184-881 1.\t\t\t507.75\t248.00 184-87-P.184-482-P.à-to 484-P.\t«70.32\t«16.08\t17.30 350.20\t7.47 75.81 184-110-P., 111.\t\t\t54.56\t 184-492, 493\t332.40\t24.58\t354.30\t173.20 184-883.\t\t\t333.56\t291.20 184-47, 48.\t98.56\t81.29\t105.14\t102.86 184-390, 397.,\t\t\t333.97\t149.53 184-043, 044-P.\t\t\t8.11\t 184-644-P., 45-P.\t\t\t230.06\t 184-707,708,\t\t\t1,902.27\t1,616.80 \t\t\t71.28\t04.70 184-882.\t\u2022\t\t1,600.93\t1,601.60 185-32.\t\t\t302.20\t24.00 185-67.\t161.02\t17.60\t150.24\t17.60 \t65.46\t7.60\t66.11\t7.60 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2025 Numéro de compte Account number Nom et adresse Name and address No du cadastre et subdivisions No.of cadastre and subdivisions Taxes munie.19G8 Munie.taxes Taxes scol.1!m,s School taxes Taxes munie.1069 Munie.taxes Taxes scol.1060 School taxes 6846 Jean-Paul Matteau & Uxor, 13,006 Forsyth, Pointe-aux-Trembles.6008 Gérard Baillargeon, 40 Dos Frênes, Pointe-aux-Trembles .6934 Claude Castonguuy, 350 Des Bouleaux, Pointeaux-Trembles.0977-21 Eli Brown et al., 772 Wildor.Outremont, P.Q.7063 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.7003-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.*.\".7003-02 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.7084 Crédit Immobilier Inc., 1260, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.7101 W.M.McCormack.5272 Doherty, Montréal.7102 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointe- aux-Trembles.7105-03 Guiseppe Piz/.uto, 0820 Papineau, app.1, Montréal.7105-04 Guiseppe Pizzuto, 0820 Papineau, app.1, Montréal.7105-05 Guiseppe Pizzuto, 6820 Papineau, app.1, Montréal.7124 Philippe Fraser, 29 De Normandie, Pointe-aux-Trembles.7132 Guy Morrow, St-Césaire, comté Kouville.7151 Paul Aubertin, 1120 Bernard O.Outremont, Montréal.7165 Victor Waskiowicz, 6660, 10e Avenue, Rosemont, Montreal.7171 Joseph Flâner, 735 Cave Circle.Ville St-Laurent.7237 Eugène Bndran, 4171 St-Denis, Montrénl.7238 Êmilien Bergeron, a/s M.Bergeron, 3998 De Bul- lion, Montréid.7241 Joseph Flâner, 735 Cave Circle, Ville St-Laurent.7257 Hector Lapierrc, 6 rue Paul, C.P.472, St-Snuveur dos Monts, Cté Terrebonne, P.Q.7292 Colin W.Paterson, 359 Melville Avenue, Westmount, Montréal.7371 Mme Henri Pigeon, 2550 Humeury, Duvernay, Laval.7398-01 Crédit Immobilier Inc., 1200, 8e Avenue, Pointeaux-Trembles.7442-01 Crédit Immobilier Inc.1200, Se Avenue, Pointeaux-Trembles.7461 Leopold Tapin, 1808 Létourneux, Montréal.7401-01 Leopold Tapin, 1808 Létourneux, Montréal.7462 L.Lalonde.a/s P.Perras.Ch.804 de la Bourse, Place Victoria, Montréal.7462-01 L.Lalonde, a/s P.Perras.Ch.804 de la Bourse, Place Victoria, Montréal.7514 Assouline et al., a/s David Stein, 145 Springrove Crescent, Outremont, Montréul.7517 Sam Stein, 146 Springrove Crescent, Outremont, Montréal.7521 Assouline et al., a/s David Stein, 145 Springrove Crescent, Outremont, Montréal.7540 Hyman Grinstein, 1350 La joie, npp.5, Montréal.7508 William Begg, 0430, 42e Avenue, app.6, Montréal 185-84.$224.71 185-313.185-342.190 2 0.108-200 à-to 265.198-202, 263.198-204, 205.198-95,96.198-393.4.84 198-394 à-to 390.198-444, 445.198-440, 447.198-448,449.199 9.199-44.9.45 199-194, 195.13.68 199-305,\"300.199-397.398.199-411 à-to 413.199-414 à-to 416.199-423,424.199-733.199-256, 257.202-102.' 7.8(i 40-24,25,26,32, 157, 163,164, 160, 240,152, 152A, 152 à-to 176,254,300, 177, 804.40-44, 45.46.28-32, 33.28-34,36.28-36 à-to 30.24.10 28-38, 30.31-32-P., 32-P____ 36-P.37-P.40-205, 206 41-7.8.30.61 40-443-P.$16.00 $224.01 392.77 $ 10.00 210.00 4.50 8.40 6.80 24.00 71.80\t159.03 18.24\t50.40 18.24\t 18.24\t 70.08 9.12\t28.20 5.00 29.04 4.20 18.24 18.29\t31.62 64.94 14.39\t43.60 8.40 40.40\t13.60 70.08 107.54\t10.12 22.00 2.83 71.83\t17.54 28.15\t7.20 72.53\t 36.37\t6.80 69.30 25.16 22.27 22.60 149.31 24.00 24.00 22.27 22.66 2,027.41 1,080.72 3,400.68 3,612.02 2,063.80 02.74 4.87 24.17 6.60 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108' année, n° 9 Numéro No du cadastre Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes de compte Nom et adresse et subdivisions munie.scol.munie.scol.munie.scol.1905 1965- 1900 1960 1967 1967 Account Name and address No.of cadnstre Munie.Scholl Munie.School Munie.School number and subdivisions taxes taxes tuxes taxes taxes taxes 2283-01 5034 0003 7209 7598 Marcel Bastien.12.878 Notre-Dame, Pointe-aux-Trembles, P.Q.Terre 205.Gauthier, G.Albert, Ltée, 4523 De Laroche, Montréal.177-486-P.822.99 Crédit Immobilier, Inc., 1260, 8e Avenue, Pointe-aux-Trembles.177-44-P., 45-P.St-Germain, Léo.199-900-P.Begg, William, 6430, 42e Avenue, app.5, Montréal.40-443-P.8840.06 31,148.80 84.28 823.72 84.06 23.72 24.28 .88 .31 3.51 .43 1.85 3.51 0.00 60.00 1.20 4.07 La Commission municipale de Québec a, le onze février 1971, autorisé une enumeration abrégée.Donné à Pointe-aux-Trembles, Québec, ce 15e jour dc février 1971.38808-8-2-o Le greffier, Guy Vanier.The Québec Municipal Comission has, on February 11, 1971, authorized a summarized description.Given at Pointe-aux-Trembles, Québec, this 15th day of February 1971.38808-8-2-o Guy Vanier, City Clerk.Ventes d'effets non reclames Sales of Unclaimed Baggage Compagnie des Chemins dc Fer Nationaux du Canada Réclamations marchandises Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le premier jour de septembre 1970, et non réclamés aux bureaux dc la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada, à divers endroits dc la Région du Saint-Laurent des Chemins de Fer Nationaux du Canada seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Allan Harvey & Company, encanteurs, 2276 est, rue Ontario, Montréal, à midi, le mercredi 10 mars 1971, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, Québec, le 28 janvier 1971.Le directeur 38509-6-5-o W.W.R.Bradford.Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique Avis est par les présentes donné que tous les effets de bagage reçus avant le premier jour de novembre 1970, et non réclamés aux bureaux de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, seront vendus aux enchères par Fraser Brothers (Canada) Limited, 4950 de la Savane, Montréal, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-neuvième (29e) jour de mars 1971, conformément à la Loi des Chemins de Fer du Canada, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.Montréal, le 1er février 1971.Le superviseur, 38669-7-G-o G.P.Watson.Canadian National Railway Company Merchandise Claims Department Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of September 1970, and still remaining unclaimed in the offices of the Canadian National Railway Company, at different points in the St-Lawrence Region of the Canadian National Railway Company, will be sold at public auction to the highest bidder by Allan Harvey & Company, Auctioneers, 2276 Ontario Street East, Montreal, at 11:30 a.m., Wednesday, March 10,1971, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, Québec, January 28, 1971.W.W.R.Bradford.38509-6-5-o Manager.Canadian Pacific Railway Company Notice is hereby given that all baggage received prior to the first day of November 1970, and still remaining unclaimed in the offices of Canadian Pacific Railway Company, will be sold by public auction to the highest bidder by Fraser Brothers (Canada) Limited, auctioneers, at 4950 de la Savane, Montreal, at ten o'clock in the forenoon, on Monday, the twenty-ninth (29th) day of March 1971, under the authority of the Railway Act of Canada, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.Montreal, February 1, 1971.G.P.Watson, 38669-7-6-0 Supervisor. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February '27, 1971, Vol.103, No.9 2027 Arrêtés en Conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 232 Québec, le 20 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil CONCERNANT une modification au règlement No 1 dc l'aide sociale.Attendu Qu'en vertu de Partie e 48 de a Loi dc l'Aide sociale (chapitre 63 des Lois dc 1969), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementât ion; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil numéro 3491 du 17 septembre 1970, des règlements ont effectivement été adoptés sous l'empire de cette même I«oi; Attendu que l'article 2.01 du règlement No 1 de l'aide sociale comporte des difficultés d'application relativement lourdes pour le personnel des bureaux régionaux et locaux d'aide sociale; Attendu que la référence au paragraphe 4.04 mentionnée au sous-paragraphe 3 du paragraphe a) de l'article 4.05 du règlement No 1 de l'aide sociale est erronée; Il est ordonné, en conséquence, sur !a proposition du ministre des Affaires sociales: Que ledit article 2.01 soit abrogé et remplacé par le suivant à compter du 1er novembre 1970; 2.01 La valeur de l'aide mensuelle, qu'il s'agisse de l'aide en espèce, en nature ou sous forme de services, est égale au déficit entre l'ensemble des besoins ordinaires ct spéciaux d'une famille ou d'une personne seule ct l'ensemble de leurs revenus.Les revenus hebdomadaires sont truns|K>sés sur la base mensuelle en les multipliant par le facteur 4.3, lorsque la famille ou la personne seule réa'lse ces revenus pendant tout le mois.Que l'article 4.05 dudit règlement No 1 de l'aide sociale soit modifié en remplaçant au sous-paragraphe 3 du paragraphe a) du même article la référence 4.04 par 4.06.Le greffier (lu Conseil exécutif, 38850-o Julien Ciiouinahd.Arrête en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 661 Québec, le 17 février 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil Concernant la prolongation du règlement de prélèvement de neuf (9) Comités paritaires régissant le commerce de l'Alimentation dans lu Province.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'œuvre: Orders in Council Order in Council Executive Council Chamber Numln-r 232 Québec, January 20, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council.CONCERNING an amendment to Regulation No.1 on Social Aid.Whereas, under section 48 of the Social Aid Act (chapter 63 of the Statutes of 1969), the Lieutenant-Governor in Council may make regulations; WlIEREAS, regulations under such Act were made by Order in Council No.3491 ol September 17, 1970.WlIEREAS it will prove difficult for the personnel of the regional and local Sociul Aid offices to apply article 2.01 of Regulation No.1 on Social Aid: WlIEREAS the reference to article 4.04 mentioned in sub-paragraph 3 of paragraph (a) of article 4.05 of Regulation No.1 on Social Aid is erroneous; It is ORDERED, therefore, upon the recommendation ol the Minister of Social Affairs: That the said article 2.01 be abrogated and replaced by the following, from and after November 1, 1970; 2.01 The value of the monthly aid, whether it be aid in money, in kind or in the form of services, is equal to the deficit which exists between the aggregate of the ordinary and special needs of a family or individual und the aggregate of its or his income.The weekly income is calculated on a monthly basis by multiplying it by 4.3 when the family or individual is in receipt of this income for the whole month.That article 4.05 of said Regulation No.1 on Social Aid be amended by replacing reference 4.04 by reference 4.06 in sub-parogroph 3 of paragraph (a) of the same article.Julien Ciiouinahd, 38856 Cleric of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 661 Québec, February 17, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning the extension of the levy by-law of nine (9) Parity Committees governing the Food Trade in the Province of Québec.It is ordered, upon the recommendation of the Honourable Minister of Labour and Manpower: 2028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Que les règlements dc prélèvement des Comités paritaires ei-après mentionnés, soient prolongés aux mêmes taux et conditions jusqu'au 31 mai 1971; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1811 du 21 juin 1968 relativement au Comité paritaire «le l'Alimentation de Chicoutimi; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3085 du 15 octobre 1969 relativement au Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation de Drummondville; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 445 du 18 février 1969 relativement au Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation dc Jonquièrc; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2991 du 8 octobre 1969 relativement au Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation au détail à Québec; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1682 du 8 avril 1970 relativement au Comité paritaire de l'Alimentation en gros, région de Québec; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2093 du 16 juillet 1969 rclat ivement au Comité paritaire de l'alimentation au détail dc St-Hyacinthe; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1753 du 10 juin 1969 relativement au Comité paritaire dc l'alimentation au détail de Sherbrooke et région; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1754 du 10 juin 1969 relativement au Comité paritaire du commerce de détail d'Asbestos; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 3929 du 10 décembre 1969 relativement au Comité paritaire du commerce de détail de Richmond et Melbourne.Le greffier du Conseil exécutif, 3885S-0 Julien Ciiouinahd.Arrête en conseil Chambre du Conseil Executif Numéro 323 Québec, le 20 janvier 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le calcul dc l'impôt relatif à certains bénéfices reçus par des employés ct la Loi dc l'impôt provincial sur le revenu.Attendu que l'article 114 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q.1964, chapitre 69) prévoit une réduction d'impôt dans le cas de certains bénéfices reçus par des employés, concernant le droit dc souscrire à des actions; Attendu que le premier alinéa de l'article 168 dc ladite loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre du Revenu, de faire des règlements pour réduire l'impôt prévu par la présente loi, dc la manière et dans la proportion qu'il jugera à propos; \u2022 Attendu Qu'il y a lieu de rendre applicable aux années 1970 et suivantes les dispositions du règlement adopté par l'arrêté en conseil numéro 409 du 4 février 1970, émis sous l'empire de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q.1964, chapitre 69).That the levy by-laws of the Parity Committees mentioned hercinbelow be extended until May 31, 1971, without any change in rates or conditions: The by-law approved by Order in Council number 1811 of June 21, 1968, respecting the Comité paritaire dc l'Alimentation de Chicoutimi.The by-law approved by Order in Council number 3085 of October 15, 1969, respecting \"The Food Trade Parity Committee of Drummondville\".The by-law approved by Order in Council number 445 of February 18,1969, respecting Le Comité paritaire du Commerce de l'Alimentation de Jonquière.The by-law approved by Order in Council number 2991 of October 8, 1969, respecting \"The Retail Food Trade Parity Committee of Québec\".The by-law approved by Order in Council number 1682 of April 8, 1970, respecting \"The Wholesale Food Parity Committee, Quél>ec district\".The by-law approved by Order in Council number 2093 of July 16, 1969, respecting the \"Food Trade Parity Committee of St-Hyacinthe\".The by-law approved by Order in Council number 1753 of June 10, 1969, respecting \"The Parity Committee of the Retail Food Trade of Sherbrooke vicinity\".The by-law approved by Order in Council number 1754 of June 10, 1969, respecting \"The Joint Committee of the Retail Trade of Asbestos\".The by-law approved by Order in Council number 3929 of December 10, 1969, respecting the \"Richmond and Melbourne Retailers Joint Committee\".Julien Ciiouinahd, 38858-0 Clerk of the Executive Council.Order in Council Executive Council Chamber Number 323 Québec, January 20, 1971.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the computation of the tax related to certain benefits received by employees and the Provincial Income Tax Act.Whereas section 114 of the Provincial Income Tax Act, (R.S.Q.1964, chapter 69) provides for a reduction of income tax in the case of certain benefits received by employees concerning the right to acquire shares; Whereas under paragraph one of section 168 of the above mentioned Act the Lieutenant-Governor in Council, upon the recommendation of the Minister of Revenue, may make regulations to reduce the tax provided for by the said Act in such manner and to such extent as he may deem fit; .Whereas it is expedient that the provisions of the regulation passed by Order in Council number 409 of February 4, 1970, under the Provincial Income Tax Act, be made applicable to the taxation year 1970 and subsequent years. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2029 Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement concernant le calcul de l'impôt relatif à certains bénéfices reçus par des employés ct la Loi de l'impôt provincial sur le revenu ».Vraie copie certifiée.Le greffier du Conseil exécutif, Julien Ciiouinard.Règlement concernant le calcul de l'impôt relatif à certains bénéfices reçus par des employés et la Loi de l'impôt provincial sur le revenu.1° Le mode de calcul de l'impôt établi par les paragraphes 2 et 3 dc l'article 114 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q.1964, chapitre 69) est remplacé par le suivant: a) lorsque d'après les sous-paragraphes a, b, c ou d du paragraphe 1 dc l'article 114, un bénéfice est censé avoir été reçu par un employé en raison de son emploi dans une année d'imposition, l'employé doit, s'il opte en ce sens, payer comme impôt pour l'année, au lieu du montant qui serait autrement payable, un montant égal au total i) dc l'impôt qui serait payable par l'employé pour l'année si aucun bénéfice n'était ainsi censé avoir été reçu par lui dans l'année; ct ii) du montant, s'il en est, par lequel la proportion du bénéfice ainsi réputé avoir été reçu, que l'ensemble des impôts payables par l'employé pour les trois années précédant immédiatement l'année d'imposition (avant toute déduction prévue par l'article 47 ou 48 et sans compter les impôts attribuables à des bénéfices ainsi réputés avoit été reçus en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 au cours dc ces trois années) représente par rapport à l'ensemble des revenus de l'employé pour ces trois années (en excluant les bénéfices censés avoir été reçus en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 au cours des trois mêmes années), dépasse le moindre dc dix pour cent du montant du bénéfice ainsi réputé avoir été reçu ou $100.b) lorsqu'un employé qui a choisi, sous le régime du paragraphe a ci-dessus, de payer comme impôt pour une année un montant déterminé selon ledit paragraphe n'a pas résidé dans la province pendant la totalité des trois années y mentionnées, l'impôt payable d'après le paragraphe a est un montant égal à l'ensemble i) de l'impôt qui serait payable par l'employé pour l'année si aucun bénéfice n'était censé, d'après les sous-paragraphes a, b,c ou d du paragraphe 1 dc l'article 114, avoir été reçu par lui dans l'année; et ii) du montant, s'il en est, par lequel la- proportion du bénéfice ainsi réputé avoir été reçu, que l'ensemble des impôts qui auraient été payables par l'employé pour les trois années mentionnées au paragraphe a (avant toute déduction prévue par l'article 47 ou 48 ct sans compter les impôts attribuables à des bénéfices ainsi réputés avoir été reçus en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 au cours de ces trois années), s'il avait résidé dans la province pendant la totalité de ces années et si ses revenus pour ces années étaient provenus Therefore it is ordered upon the recommendation of the Minister of Revenue: That the appended regulation entitled \"Regulation concerning the computation of income tax related to certain benefits received by employees and the Provincial Income Tax Act\" be adopted.Certified true copy.Julien Ciiouinahd, Clerk of the Executive Council.Regulation concerning the computation of income tax related to certain benefits received by employees and the Provincial Income Tax Act.1.The method of computation of the tax determined by subsections 2 and 3 of section 114 of the Provincial Income Tax Act (R.S.Q.1964, chapter 69) is replaced by the following: (a) where a benefit is deemed by paragraphs a, b, c or d of subsection 1 of section 114 to have been received by an employee by virtue of his employment in a taxation year, the employee shall, if he so elects, payas tax for the year, in lieu of the amount that would otherwise be payable, an amount equal to the aggregate of (i) the tax that would be payable by the employee for the year if no benefit were so deemed to have been received by him in the year; and (ii) the amount, if any, by which the proportion of the benefit so deemed to have been received that the uggregate of the tuxes payable by the employee for the three years immediately preceding the taxation year (before any deduction permitted by section 47 or 48 und without taking into account the taxes resulting from benefits deemed to have been received under subsection 1 of section 114 during those three years) is of the aggregate of the employee's income for those three years (excluding the benefits deemed to have been received under subsection 1 of section 114 during those three years) exceeds the lesser of ten per cent of the amount of the benefit so deemed to have been received or 8100; (b) where an employee who has elected under subsection a above to pay as tax for a year an amount determined under that subsection was not resident in the province throughout the whole of the three years referred to therein, the tax payable under subsection a is an amount equal to the aggregate of (i) the tux that would be payable by the employee for the year if no benefit were deemed by paragraphs a, b, c or d of subsection 1 of section 114 to have been received by him in the year; and (ii) tlnr amount, if any, by which the proportion of the benefit so deemed to have been received that the aggregate of the taxes that would have been payable by the employee for the three years referred to .in subsection a (before any deduction permitted by section 47 or 48 and without taking into account the taxes resulting from benefits so deemed to have been received under subsection 1 of section 114 during those three years), if he had been resident in the province throughout those years and his incomes for those years had 2030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, u' 9 de sources situées dans la province, est par rapport à l'ensemble de tous ses revenus pour ces trois années (en excluant les bénéfices censés avoir été reçus en vertu du paragraphe 1 de l'article 114 au cours des trois mêmes années), dépasse le moindre de dix pour cent du montant du bénéfice ainsi réputé avoir été reçu ou $100.En pareil cas, l'option n'est pas valide à moins que l'employé n'ait produit, avec celle-ci, une déclaration de son revenu pour chacune des trois années, selon la même formule ct renfermant les mêmes renseignements que la déclaration qu'il aurait été tenu de produire s'il avait été résidant dans la province durant lesdites années.2° Le présent règlement s'applique aux années d'imposition 1970 ct suivantes.Toutefois, la limite dc $100, concernant le montant maximum qui peut être déduit dans le mode de calcul prévu par ce règlement, n'a pas d'application dans le cas d'un bénéfice reçu conformément à une entente antérieure au 30 mars 1966.38857-0 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 233 > Québec, le 20 janvier 1971 Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant une modification au règlement numéro 2 de l'aide sociale.Attendu qu'en vertu de l'article 48 de la lx>i dc l'Aide sociale (chapitre 63 des lois dc 1969), le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir dc réglementation; Attendu Qu'aux termes de l'arrêté en conseil numéro 3491 du 17 septembre 1970, des règlements ont effectivement été adoptés sous l'empire de cette même loi; Attendu qu'cp raison de l'implantation du régime d'assurance-malndie, il est devenu nécessaire «l'apporter certaines modifications aux règlements précités, notamment au règlement numéro 2; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires sociales: Que l'article 2.01 du règlement numéro 2 de l'aide sociale soit modifié de la façon suivante à compter du 1er novembre 1970: a) en remplaçant le paragraphe « c * de la façon suivante: le coût des lunettes et lentilles réfractives prescrites par un professionnel dc la santé conventionné dans le cadre du Régime dc l'assurance-maladie, pour aider une personne à couvrir ce besoin et sujet à vérification de la facture acquittée.\u2014bureau local: $10 lentilles simples sans mouture, $15 lentilles bifocales sans monture, $20 lentilles simples avec monture, $25 lentilles bifocales avec monture, $45 lentilles pour opéré de cataracte, $10 monture.been from sources within the Province is of the aggregate of all his incomes for those three years (excluding the benefits deemed to have been received under subsection 1 of section 114 during those three years), exceeds the lesser of ten per cent of the amount of the benefit so deemed to have been received, or $100.In such a case, the election is not valid unless the employee has filed with it a return of his income for each of the three years in the same form and containing the same information as the return that he would have been requireil to file if he had been resident in the province in those years.2.This regulation shall apply to the taxation year 1970 and subsequent years.The $100 limit, however, concerning the maximum amount deductible by the method of computation provided for by this regulation does not apply in the case of a benefit received under an agreement entered into before March 30, 1966.38857-0 Order in Council Executive Council Chamber Number 233 Québec, January 20.1971 Present: The Lieutenant-Governor in Council Concerning an amendment to Regulation No.2 on Social Aid.Whereas, under section 48 of the Social Aid Act (chapter 63 of the Statutes of 1969), the Lieutenant-Governor in Council may make regulations; Whereas regulations under such act were made by Order in Council No.3491 of September 17, 1970; Whereas owing to the setting up of the Health Insurance Plan, it has become necessary to amend the abovementioned regulations, in particular Regulation No.2; It is ordered, therefore, upon the recommendation of the Minister of Social Affairs: That article 2.01 of Regulation No.2 on Social Aid be amended in the following way as of November 1, 1970: (a) by re-writing paragraph \"c\" in the following way: the cost of eye-glasses and refractive lenses prescribed by a professional bound by an agreement within the scope of the Health Insurance Plan, to assist the person to meet this need and subject to verification of the paid statement, \u2014local office: \u2022 $10 for «impie lenses without frames, $15 for bifocal lenses without frames, $20 for simple lenses with frames, $25 for bifocal lenses with frames, $45 for lenses for persons operated on for cataracts, $10 for frames; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2031 6) en introduisant le paragraphe « / » suivant: \u2014 le coût, à la Régie de l'assurancc-mnladie, des services fournis par un optométriste.conformément à l'entente intervenue entre le ministre et l'Association des opto-métristes; c) en changeant l'appellation du paragraphe «/» actuel qui devient « g »; d) en abrogeant les paragraphes « g » et « h » dudit article; c) en changeant l'appellation du paragraphe « i» actuel qui devient « h *.Le greffier du Conseil exécutif, 38856-o Julien Ciiouinard.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 663 Québec, le 17 février 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil CONCERNANT la prolongation du règlement de prélèvement dc quatre (4) Comités paritaires régissant des métiers connexes à l'Industrie du Bâtiment.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable Ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que les règlements de prélèvement des Comités paritaires ci-après mentionnés, soient prolongés aux mêmes taux et conditions jusqu'au 31 mai 1971; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1811 du 17 juin 1969 relativement au Comité paritaire des métiers «le la métallurgie de la région de Québec; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 1226 du 18 mars 1970 relativement au Comité paritaire dc l'Industrie du Verre du district de Québec; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2990 du 8 octobre 1969 relativement au Comité paritaire de l'Industrie du verre plat de Montréal; Règlement approuvé par l'arrêté en conseil numéro 719 du 19 mars 1969 relativement au Comité Conjoint «les Matériaux de construction (Fer-et Bronze d'Ornementation).Le greffier du Conseil exécutif, 38858-0 Julien Ciiouinard.Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 664 Québec, le 17 février 1971.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la prolongation du règlement de prélèvement dc dix-sept (17) Comités paritaires régissant divers services ou industries dans la Province.Il est ordonné, sur la proposition de l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre: Que les règlements de prélèvement des Comités paritaires ci-après mentionnés, soient prolongés aux mêmes taux et conditions jusqu'au 31 mai 1971; (6) by introducing a new paragraph as fol'ows: the cost, to the Health Insurance Board, of services rendered by an optometrist, in accordance with the agreement reached between the Minister and the Association of Optometrists; (c) by designating the existing pnragraph \"f\" as new paragraph \"g\": ( payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The interest rate may be the same for the whole issue; but, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the table of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971.Tableau d'amortissement \u2014 3286,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$14,000 1er avril 1973.15,500 1er avril 1974.16,000 1er avril 1975.17,500 1er avril 1976.18,500 1er avril 1977.9,000 1er avril 1978.9,500 1er avril 1979.10,000 1er avril 1980.10,000 1er avril 1981.11,000 1er avril 1982.11,500 1er avril 1983.12,000 1er avril 1984.13,000 1er avril 1985.13,500 1er avril 1986.14,500 1er avril 1987 .4,500 1er avril 1988.5,000 1er avril 1989.5,500 1er avril 1990.6,000 1er avril 1991.69,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans._ Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $7,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant Table of redemption \u2014 $286,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.$14,000 \u2022 April 1, 1973.15,500 April 1, 1974.16,000 April 1, 1975.17,500 April 1, 1976.18,500 April 1, 1977.9,000 April 1, 1978.9,500 April 1, 1979.10,000 April 1, 1980.10,000 April 1, 1981.11,000 April 1, 1982.11,500 April 1, 1983.12,000 April 1, 1984.13,000 April 1, 1985.13,500 April 1, 1986.14,500 April 1, 1987.4,500 April 1, 1988.5,000 April 1,1989.5,500 April 1, 1990.6,000 April 1, 1991.69,500 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: l.Onc- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One- to 15-ycar serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixcd-tcrm bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year for the one part and as 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $7,000, and, if greater than the latter amount, the said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February £7, 1971, Vol.103, No.9 2067 compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2011 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant dc S69.500 comprend un solde de 863,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er avril 1992.S 1,000 1er avril 1993.1,000 1er avril 1994.1,500 1er avril 1995.1,500 1er avril 1996.1,500 1er avril 1997.2,000 1er avril 1998.2,000 1er avril 1999.2,000 1er avril 2000.2,500 1er avril 2001.2,500 1er avril 2002.3,000 1er avril 2003.3,000 1er avril 2004 .3,500 1er avril 2005.4,000 1er avril 2006.4,000 1er avril 2007 .4,500 1er avril 2008.5,000 1er avril 2009.5,500 1er avril 2010.6,000 1er avril 2011.7,000 L'adjudicataire s'engage ù payer les obligations, capital ct intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Stc-Foy.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 869,500, et seul cet excédent sera rachetablc par anticipation au pair le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements Nos: 59 \u2014 S105.500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 150 \u2014 811,000 \u2014 voirie; 171 \u2014 S76.000 \u2014 aqueduc et égouts; 173 \u2014 844,000 \u2014 voirie; 179 \u2014 833,500 \u2014 achat de moto-niveleuse; 181 \u2014 810,000 \u2014 achat de machineries; 184 \u2014 86,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 16 mars 1971, table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of April 1, 2011 of the renewable part hereafter mentioned.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity dale of April 1, 1991 in the amount of 869,500 includes a balance of S63.000 renewable for an additional period of 20 years, and maturing as follows: Year Capital April 1, 1992.S 1,000 April 1,1993.1,000 April 1,1994.1,500 April 1, 1995.1,500 April 1, 1996.1,500 April 1, 1997 .2,000 April 1, 1998.2,000 April 1,1999.2,000 April 1, 2000.2,500 April 1, 2001.2,500 April 1,2002.3,000 April 1, 2003.3,000 April 1,2004.3,500 April 1, 2005.4,000 April 1, 2006.4,000 April 1,2007 .4,500 April 1, 2008.5,000 April 1, 2009.5,500 April 1,2010.6,000 April 1,2011.7,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at St.Foy.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they arc issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 869,500 and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par on April 1st of each year for the amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: Nos: 59 \u2014 8105,500 \u2014 renewal of loan; 150 \u2014 811,000 \u2014 roads; 171 \u2014 876,000 \u2014 aqueduct and sewers; 173 \u2014 S44.000 \u2014 roads; 179 \u2014 833,500 \u2014 purchase of a \"moto-nivcleuse\"; 181 \u2014 810,000 \u2014 purchase of machinery; 184 \u2014 86,000 \u2014 refinancing expenses.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council which will be held on Tuesday, 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 108- année, n° 9 à 8 heures du soir, Hôtel de Ville, 4264, rue St-Félix, St-Félix-du-Cap-Rouge, comté de Québec, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Félix-du-Cap-Rouge (Comté de Québec), ce 18 février 1971.Le secrétaire-trésorier, L.-A.Bomb audi ki'.Hôtel de ville, 4264, rue St-Félix, St-Fclix-du-Cap-Rouge, comté de Québec, P.Q.Téléphone: 651-1225, code 418.38915-o March 16, 1971 at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 4264 St-Félix Street, St-Félix-du-Cap-Rouge, county of Québec, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St-Félix-du-Cap-Rouge (County of Québec), February 18, 1971.L.-A.Bombardier, Secretary-Treasurer.Town Hall, 4264 St-Félix Street, St-Félix-du-Cap-Rouge, county of Québec, P.Q.Telephone: 651-1225, code 418.38915 Ville de Saintc-Thérèsc-Oucst Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Rosaire G.Brisson, secrétaire-trésorier, Edifice municipal, 901, boulevard Sainte-Thérèse-Ouest, Sainte-Thérèse-Ouest, comté de Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 16 mars 1971, pour l'achat de 8734,000 d'obligations de la ville de Sainte-Thérèse-Ouest, comté de Terrebonne, datées du 1er avril 1971 ct remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7]/2% ni supérieur à 8J-^% payable semi-annuellement les 1er avril ct 1er octobre dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Town of Saintc-Thérèse-Ouest County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Rosaire G.Brisson, Secretary-Treasurer, Municipal Building, 901 Saintc-Thérèsc-Oucst Boulevard, Sainte-Thérèse-Ouest, county of Terrebonne, Québec, until 8:00 o'clock in the evening, Tuesday, March 16, 1971, for the purchase of a bond issue of 8734,000, bonds of the town of Sainte-Thérèse-Ouest, county of Terrebonne, dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate of not less than 7J-£%, nor more than S}/>%, payable semi-annually on April 1st and October 1st each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest will be calculated from April 1, 1971.Tableau d'amortissement \u2014 $734,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$12,000 1er avril 1973.12,000 1er avril 1974.14,000 1er avril 1975.15,000 1er avril 1976.16,000 1er avril 1977.18,000 1er avril 1978.20,000 1er avril 1979.22,000 1er avril 1980 .24,000 1er avril 1981.26,000 1er avril 1982 .29,000 1er avril 1983.32,000 1er avril 1984.35,000 1er avril 1985.38,000 1er avril 1986 .42,000 1er avril 1987.16,000 1er avril 1988.18,000 1er avril 1989.20,000 1er avril 1990.22,000 1er avril 1991.303,000 Table of redemption \u2014 S73/t,000 - 20 years Year Capital April 1, 1972.$12,000 April 1,1973.,.12,000 April 1,1974.14,000 April 1, 1975.15,000 April 1, 1976.16,000 April 1, 1977.18,000 April 1, 1978.20,000 April 1,1979 .22,000 April 1, 1980.24,000 April 1,1981.26,000 April 1, 1982 .29,000 April 1,1983.32,000 April 1, 1984.35,000 April 1, 1985.38,000 April 1, 1986.42,000 April 1,1987.16,000 April 1,1988.18,000 April 1,1989 .20,000 April 1, 1990.22,000 April If 1991.303,000 QJJÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2069 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté i\\ la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 uns avec le solde reporté ù 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à S40.000 et si supérieur à ce dernier montnnt, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte tics tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2001 de la partie renouvelable ci-après mentionnée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril_1991 au montant dc S303.000 comprend un solde de S279.000 renouvelable pour une période additionnelle dc 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 1er avril 1992.$18,000 1er avril 1993.20,000 1er avril 1994.22,000 1er avril 1995.24,000 1er avril 1996.26,000 1er avril 1997.28,000 1er avril 1998.31,000 1er avril 1999.34,000 1er avril 2000.36,000 1er avril 2001.40,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Sainte-Thérèse.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur ik $303,000 ct seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances appa-apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One- to 10-ycar serial bonds with the balance carried forwurd to the tenth year.2.One- to 15-ycar serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance us 20-ycar fixcd-tcrm bonds.4.One- to 10-ycar scriul bonds with the buluncc carried forwurd to ten years for one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-ycar fixed-term bonds shall not be for an amount less than $40,000, and if greater than the latter amount, the surplus only must comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, the April 1, 2001 maturity of the renewable part hereinafter mentioned being excluded.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The April 1,1991 maturity, in the amount of $303,000, covers a balance of $279,000, renewable for an additional 10-year period and maturing as follows: Year Capital April 1, 1992.$18,000 April 1,1993.20,000 April 1,1994.22,000 April 1, 1995.24,000 April 1, 1996.26,000 April 1,1997.28,000 April 1,1998.31,000 April 1,1999.34,000 April 1, 2000.36,000 April 1,2001.40,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Sainte-Thérèse.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they arc issued partly as 20-ycar fixed-term bonds for un amount greater than $303,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a_ certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bondsto the date of their delivery is included or not in the price of the tender. 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 267 \u2014 S45.000\u2014 acquisition de lots par expropriation; 276 \u2014 $385,000 \u2014 aqueduc, égouts; 280 \u2014 $15,000 \u2014 aqueduc, égouts; 281 \u2014 $7,000 \u2014 voirie ; 2S2 \u2014 $5,000 \u2014 électricité; 302 \u2014 $53,000 \u2014 services récréatifs et communautaires; RV \u2014 3 \u2014 $224,000 \u2014 création d'un fonds dc roulement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mardi, le 16 mars 1971, à 8 heures du soir, Edifice municipal, 901, boulevard Sainte-Thérèse-Ouest, Sainte-Thérèse-Ouest, comté de Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Thérèse-Oucst (Comté dc Terrebonne), ce 16 février 1971.Le secrétaire-trésorier.Rosaire C.Buisson.Édifice municipal, 901, boul.Stc-Thérèsc-Ouest, Saintc-Thérèsc-Oucst, Comté de Terrebonne, P.Q.Téléphone: 435-6571, code 514.38916-0 i Paroisse dc Saint-Charlcs-de-Lachenaic Comté dc L'Assomption Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues pur le soussigné Jean Poirier, secrétaire-trésorier, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, bureau dc la corporation, 3341, rue Notre-Dame, Saint-Charles-de-Lachenaie, comté de L'Assomption, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, École Notre-Dame, rue Notre-Dame, Saint-Charles-de-Lachenaie, comté dc L'Assomption, P.Q., mercredi, le 17 mars 1971, pour l'achat de $270,000 d'obligations de la paroisse de Saint-Charles-de-Lachenaie, comté de L'Assomption, datées du 1er avril 1971 et remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 734%.r' supérieur à 834%, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.Tableau d'amortissement \u2014 S270,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$ 4,500 1er avril 1973.4,500 1er avril 1974 .4,500 1er avril 1975.5,000 1er avril 1976.5,000 1er avril 1977 .5,500 1er avril 1978.6,500 1er avril 1979.7,000 1er avril 1980.7,000 1er avril 1981.8,000 1er avril 1982.8,000 The said bonds will be issued under the following by-laws: 267 \u2014 $45,000 \u2014 purchase of lots by means of expropriation; 276 \u2014 $385,000\u2014aqueduct, sewers; 280 \u2014$15,000 \u2014aqueduct, sewers; 281 \u2014$7,000 \u2014 roads ; 282 \u2014 $5,000 \u2014 electricity ; 302 \u2014 853,000 \u2014 recreational and community services; RV-3 \u2014 $224,000 \u2014 formation of a working capital.Tenders will be opened and considered ut a meeting of the council to be held Tuesday, March 16, 1971, at 8:00 o'clock in the evening, at the Municipal Building, 901 Suinte-Thérèsc-Oucst Boulevard, Saintc-Thérèsc-Ouest, county of Terrebonne, Québec The council does not bind itself to accept the highest nor any of the tenders.Sainte-Thérèse-Ouest, (County of Terrebonne), February 16, 1971.Rosaire G.Brisson, Secretary-Treasurer.Municipal Building, 901 Sainte-Thérèse-Ouest Blvd., Sainte-Thérèse-Ouest, county of Terrebonne, Québec.\u2022 Telephone: 435-6571, Code 514.38916 Parish of Saint-Charlcs-de-Lachenaic County of L'Assomption Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jean Poirier, Secretary-Treasurer, until 5:00 o'clock p.m., at the office of the corporation 3341 Notre-Dame Street, Saint-Charles-de-Lachenaie,' county of L'Assomption, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at Notre-Dame School, Notre-Dame Street, Saint-Charles-de-Lachc-naie, county of L'Assomption, P.Q., on Wednesday, March 17, 1971, for the purchase of a bond issue of 8270,000, bonds of the parish of Saint-Charles-de-Lachenaie, county of L'Assomption, dated April 1, 1971 and redeemable serially from April 1, 1972 to 1, 1991 inclusively, with interest at a rate of not less than 7J4%, nor more than 2>]/o%, payable semiannually on April 1st and October 1st each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest will be calculated as of April 1, 1971.Table of redemption \u2014 $270,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.$ 4,500 April 1,1973 .4,500 April 1,1974.4,500 April 1,1975 .5,000 April 1, 1976.5,000 April 1, 1977.5,500 April 1,1978.6,500 April 1,1979.7,000 April 1,1980.7,000 April 1, 1981.8,000 April 1,1982.8,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2071 1er avril 1983.$8,500 1er avril 1984.10,000 1er avril 1985.'.10,000 1er avril 1986.11,000 1er avril 1987.12,000 1er avril 1988.13,000 1er avril 1989.14,000 1er avril 1990.14,000 1er avril 1991.112,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Ogligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 810,500 ct si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2006 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant de 8112,000 comprend un solde dc 896,000 renouvelable pour une période additionnelle de 15 ans, et échéant comme suit: April 1, 1983 .88,500 April 1, 1984.10,000 April 1,1985.10,000 April 1,1986.11,000 April 1, 1987.12,000 April 1,1988., 13,000 April 1, 1989.14,000 April 1,1990.14,000 April 1, 1991.,.112,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One- to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One- to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $10,500, and if greater than the later amount, this surplus only must comprise one or several complete annual amortizations, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, the April 1, 2006 maturity of the renewable part hereinafter mentioned being excluded.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and they shall comprise one only pf the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The April 1,1991 maturity, in the amount of $112,000 covers a balance of $96,500 renewable for an additional 15-year period and maturing as follows: Année Capital 1er avril 1992.$ 3,500 1er avril 1993.4,000 1er avril 1994.4,000 1er avril 1995.4,000 1er avril 1996.4,500 1er avril 1997.5,000 1er avril 1998.5,500 1er avril 1999.6,000 1er avril 2000.7,000 1er avril 2001.7,500 1er avril 2002.8,000 1er avril 2003.8,000 1er avril 2004.9,000 1er avril 2005.10,000 ' 1er avril 2006.10,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Terrebonne.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Year Capital April 1, 1992.$ 3,500 April 1,1993.4,000 April 1,1994.4,000 April 1,1995.4,000 April 1, 1996.4,500 April 1, 1997.5,000 April 1,1998.5,500 April 1,1999.6,000 April 1,2000.7,000 April 1, 2001.7,500 April 1,2002.8,000 April 1,2003.8,000 April 1,2004.9,000 April 1,2005.10,000 April 1,2006.10,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Terrebonne.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure. 2072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 Lesdites obligations ne seront pas raebetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8112,000 et seul cet excédent sera rachctable par anticipation, au pair, le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission; conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 107 \u2014 S106,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 148 \u2014 879,500 \u2014 aqueduc, égouts; 150 \u2014 $14,400 \u2014 aqueduc, égouts; 150-A \u2014 812,800 \u2014 aqueduc, égouts; 150-11 \u2014 818,800 \u2014 aqueduc, égouts; 150-C \u2014 S.32,500 \u2014 voirie; 158 \u2014 S6.000 \u2014 frais dc refinancement du règlement numéro 107.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 17 mars 1971, à S heures du soir, École Notre-Dame, rue Notre-Dame, Saint-Charles-dc-Lachcnaie, comté de L'Assomption, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Charles-dc-Lachcnaic (Comté de L'Assomption), ce 18 février 1971.Le secrétaire-trésorier, Jean Poirier.Bureau de la corporation, 3341, rue Notre-Dame, St-Charles-dc-Lachenaie (L'Assomption), P.Q.Téléphone: 861-2651 Travail (Mtl), 666-3677 Résidence (St-Ch.-de-Lac), code 514.38930-o Municipalité dc Touraine Comté de Gatincau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean Gervais, secrétaire-trésorier, Hôtel de Ville, 12, avenue Picardie, Touraine, comté de Gatineau, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 15 mars 1971, pour l'achat de 8218,000 d'obligations de la municipalité de Touraine, comté de Gatineau, datées du 1er avril 1971 et remboursables par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 714%, ni supérieur à 8J4%, payable semi-annuellcment les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than 8112,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued under the following by-laws: 107 \u2014 8106,000 \u2014 loan renewal; 148 \u2014 879,500 \u2014 aqueduct, sewers; 150 \u2014 S14.400 \u2014 aqueduct, sewers; 150-A \u2014 $12,800 \u2014 aqueduct, sewers; 150-B \u2014 818,800 \u2014 aqueduct, sewers; 150-C \u2014 $32,500 \u2014 roads; 158 \u2014 86,000 \u2014 costs for refinancing by-law number 107.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held Wednesday, March 17, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at Notre-Dame School, Notre-Dame Street, Saint-Charles-de-Lachenaie, county of L'Assomption, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St-Charles-de-Lachenaic (County of L'Assomption), February 18, 1971.Jean Poirier, Secretary-Treasurer.Office of the corporation, 3341 Notre-Dame Street, St-Charles-de-Lachenaie (L'Assomption), P.Q.Telephone: 861-2651 Office (Mtl), 666-3677 Home (St.Ch.-de-Lac), code 514.38930 Municipality of Touraine County of Gatineau Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jean Gervais, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine, county of Gatineau, P.Q.until 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 15, 1971, for the purchase of an issue of $218,000 of bonds for the municipality of Touraine, county of Gatineau, such bonds will be dated April 1, 1971 and will be redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7}4%> uor more than 8J^%, payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; but, if more than one rate should be used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2073 Tableau d'amortissement \u2014 $218,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.S 4,000 1er avril 1973.4,000 1er avril 1974.4,000 1er avril 1975.4,000 1er avril 1976.4,000 1er avril 1977.5,000 1er avril 1978 .5,500 1er avril 1979 .5,500 1er avril 1980.7,000 1er avril 1981.7,000 1er avril 1982.7,500 1er avril 1983 .8,500 1er avril 1984.9,000 1er avril 1985.10,000 1er avril 1986.11,000 1er avril 1987.12,500 1er avril 198S.13,000 1er avril 1989.15,000 1er avril 1990.15,500 1er avril 1991.66,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 87,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2001 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant de 866,000 comprend un solde de $48,500 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans et échéant comme suit: Table of redemption \u2014 8218,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.:.$ 4,000 Aprill, 1973 .4,000 Aprill, 1974.4,000 April 1, 1975.4,000 Aprill, 1976.4,000 April 1, 1977.5,000 Aprill, 1978.5,500 April 1,1979.5,500 April 1,1980.7,000 April 1, 1981.7,000 April 1, 1982.7,500 Aprill, 1983.8,500 Aprill, 1984.9,000 April 1, 1985.10,000 Aprill, 1986.11,000 April 1, 1987.12,500 Aprill, 1988.13,000 Aprill, 1989.15,000 Aprill, 1990.15,500 Aprill, 1991.66,000 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered : 1.One to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One to 15-ycar serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One to 10-year serial bonds with the balance carried over 10-year for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than 87,000, and if greater than the latter amount, the said part must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starting with the last maturities excluding the maturity of April 1, 2001 of the renewable part hereafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudications shall be made according to law.The maturity of April 1, 1991 in the amount of $66,000 includes a balance of $48,500 renewable for an additional 10-year period and maturing as follows: Année Capital Year Capital 1er avril 1992.$3,000 April 1, 1992.$3,000 1er avril 1993.3,500 April 1, 1993.3,500 1er avril 1994.3,500 April 1, 1994.3,500 1er avril 1995.4,000 April 1, 1995.4,000 1er avril 1996 .4,500 April 1, 1996.4,500 1er avril 1997.5,000 April 1, 1997.5,000 1er avril 1998 .5,500 April 1, 1998.5,500 1er avril 1999.6,000 April 1, 1999.6,000 1er avril 2000 .6,500 April 1, 2000 .6,500 1er avril 2001.7,000 April 1, 2001.7,000 2074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé payable au pair à Pointe-Gatineau.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S66.000, et seul cet excédent sera rachctablc par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté àgal à 1% du montant dc l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements Nos 417 \u2014 835,000 \u2014 voirie, aqueduc, égouts; 418 \u2014 846,500 \u2014 voirie, aqueduc, égouts; 420 \u2014 83,500 \u2014 voirie; 421 \u2014 814,000 \u2014 voirie; 422 \u2014 84,000 voirie; 423 \u2014 810,000 \u2014 voirie, aqueduc, égouts; 425 \u2014 815,000 \u2014 voirie; 426 \u2014 815,000 voirie; 433 \u2014 875,000 \u2014 aqueduc ct égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue lundi, le 15 mars 1971, à 8 heures du soir, Hôtel de Ville, 12, avenue Picardie, Touraine, comté dc Gatineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Touraine (Comté de Gatineau), ce 18 février 1971.Le secrétaire-trésorier, Jean Gervais.Hôtel de ville, 12, avenue Picardie, Touraine (Comté dc Gatineau), P.Q.Téléphone : 776-5591, code 819.38914-o La commission scolaire régionale de Chambly Siège social: 185, rue St-Jean, Suite 201, Longueuil, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées ct portant l'inscription 1 Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné André Chartier, secrétaire-trésorier, Bureau de la commission, 185, rue St-Jean, Suite 201, Longueuil, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 15 mars 1971, pour l'achat de 82,550,000 d'obligations de la commission scolaire régionale de Chambly, datées du 1er avril 1971 et remboursables en série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement avec intérêt à un taux non inférieur à 7]A%, ^supérieur à 8}4%.payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1971.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Pointe-Gatineau.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued partly as 20-ycar fixed-term bonds for an amount greater than 866,000, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to by-laws Nos 417 \u2014 835,000 \u2014 roads, aqueduct, sewers; 418 \u2014 846,500 \u2014 roads, aqueduct, sewers; 420 \u2014 83,500 \u2014 roads; 421 \u2014 814,000 \u2014 roads; 422 \u2014 84,000 \u2014 roads; 423 \u2014 810,000 \u2014 roads, aqueduct, sewers; 425 \u2014 815,000 \u2014 roads; 426 \u2014 815,000 \u2014 roads; 433 \u2014 875,000 \u2014 aqueduct and sewers.The tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, March 15, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine, county of Gatineau, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Touraine (County of Gatineau), February 18, 1971.Jean Gervais, Secretary-Treasurer.Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine (County of Gatineau), P.Q.Telephone : 776-5591, code 819.38914 Chambly Regional School Board Head Office: 185 St-Jean Street, suite 201 Longueuil, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned André Chartier, Secretary-Treasurer, at the Office of the Board, 185 St-Jean Street, Suite 201.Longueuil, P.Q., up to 8:00 o'clock p.m., Monday, March 15, 1971, for the purchase of an issue of 82,550,000 of bonds for the Chambly Regional School Board such bonds will be dated April 1, 1971, and redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively with interest at a rate not less than 7J4%> nor more than 8J4%.payable semi-annually on April 1st and October 1st each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest will be calculated as from April 1, 1971.M QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2075 Tableau d'amortissement \u2014 $2,660,000 \u2014 SO ans Annie Capital 1er avril 1972.$ 47,000 1er avril 1ÏÏ73 .52,000 1er avril 1974 .56,000 1er avril 1975 .61,000 1er avril 1976 .68,000 1er avril 1977 .74,000 1er avril 1978 .82,000 1er avril 1979 .89,000 1er avril 1980.97,000 1er avril 1981.107,000 1er avril 1982.117,000 1er avril 1983.128,000 1er avril 1984.140,000 1er avril 1985.153,000 1er avril 1986.168,000 1er avril 1987.184,000 1er avril 1988 .201,000 1er avril 1989 .221,000 1er avril 1990.241,000 1er avril 1991.264,000 Table of rédemption \u2014 S2,660,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.S 47,000 April 1, 1973.52,000 Aprill, 1974.56,000 Aprill, 1975.61,000 Aprill, 1976.\u2022.68,000 Aprill, 1977.74,000 April 1, 1978.82,000 Aprill, 1979.89,000 April 1, 1980 .97,000 Aprill, 1981.107,000 Aprill, 1982.117,000 Aprill, 1983.128,000 Aprill, 1984.140,000 April 1, 1985.153,000 Aprill, 1986.168,000 Aprill, 1987.184,000 April 1, 1988 .201,000 Aprill, 1989.221,000 Aprill, 1990 .241,000 April 1,1991.264,000 La commission scolaire régionale de Chambly, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (17 Eliz.U, Bill 64, sanctionné le 5 juillet 1968) demandera au ministre dc l'Éducation d'effectuer à même les subventions ù être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal ct les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icellc si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à ia quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté & 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à §264,000 ct si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1991.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut ct ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudiction sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Longueuil.The Chambly Regional School Board availing itself of section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (17 Eliz.II, Bill 64 assented to on July 5, 1968), has requested the Minister of Education to effect, from the grants to be paid annually by him to the said school board, the deposit in trust, in the hands of the Minister of Finance, of sums sufficient to pay entirely the principal and the interest of the present bond issue and of any renewal thereof if required.Moreover, the following terms and conditions only shall be considered : 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.One- to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.One- to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.One- 'o 10-yenr serial bonds with the balance carried' forward to 10-year for one part and as 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than S264.000 and if higher than the latter amount, the said surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of maturities, excluding the maturity of April 1, 1991.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only, and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Longueuil. 2076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, »° 9 Le capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas racbetablcs par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à S264.000, ct seul cet excédent sera racbctublc par anticipation au pair le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment dc leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions d'emprunt datées des: 24 mars 1970 \u2014 §2,000,000 \u2014 construction d'une école secondaire polyvalente ù ville Laflèchc; 13 octobre 1970 \u2014 3550,000 \u2014 coût excédentaire du complexe polyvalent.Les soumissions seront ouvertes et considérées ù une séance des commisaircs d'écoles qui sera tenue lundi, le 15 mars 1071, à S heures du soir, Bureau de la commission, 185, rue St-Jean, Suite 201, Longueuil, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Longueuil, ce 22 février 1971.Le secrétaire-trésorier, André Chartier, Bureau de la commission, 185, rue St-Jeàn, Suite 201, Longueuil, P.Q., Téléphone: 679-8720, code 514.38939-0 Ville dc Bélair Comté de Portneuf Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Claude Grenier, secrétaire-trésorier, Hôtel dc ville, 220, boulevard Saint-Gérard, Bélair, comté de Portneuf, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 15 mars 1971, pour l'achat de 3253,000 d'obligations de la ville dc Bélair, comté de Portneuf, datées du 1er avril 1971 et rembrou-sablcs par série du 1er avril 1972 au 1er avril 1991 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7J4%» ni supérieur à 8)4%, payable semi-annucllemcnt ies 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour adjudication seulement, l'intérêt sera calculé a compter du 1er avril 1971.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure, as well as at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation, save if they are issued partly as 20-year fixcd-tcrm bonds for an amount greater than 3264,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the table of maturities of the issue appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the loan resolutions dated: March 24, 1970 \u2014 32,000,000 \u2014 construction of a polyvalent secondary school in the town of Laflèchc; October 13, 1970 \u2014 3550,000 surplus cost of the polyvalent school.The tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Monday, March 15, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Office of the Board, 185 St-Jean Street, Suite 201, Longueuil, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Longueuil, February 22, 1971.André Chartier, Secretary-Treasurer.Office of the Board, 185 St-Jean Street, Suite 201, Longueuil, P.Q.Telephone: 679-8720, Code 514.38939 Town of Bélair County of Portneuf Public notice is hereby given that sealed tenders bearing the inscription \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Claude Grenier, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 220 Saint-Gérard Boulevard, Bélair, county of Portneuf, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 15, 1971, for the purchase of an issue of 3253,000 of bonds for the town of Bélair, county of Portneuf, such bonds will be dated April 1, 1971 and will be redeemable serially from April 1, 1972 to April 1, 1991 inclusively, with interest at a rate not less than 7J4%> nor more than 8>4%> payable semi-annually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; but, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several whole annual amortizations, as shown on the tables of redemption in this notice.For adjudication only, interest shall be calculated as from April 1, 1971. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 207?Tableau d'amortissement \u2014 $253,000 \u2014 20 ans Année Capital 1er avril 1972.$ 4,500 1er avril 1973 .5,000 1er avril 1974.5,500 1er avril 1975.5,500 1er avril 1976.'6,500 1er avril 1977.7,000 1er avril 1978 .8,000 \u2022 1er avril 1979.8,000 1er avril 1980.8,000 1er avril 1981.9,000 1er avril 1982 .9,500 1er avril 1983.11,000 1er avril 1984.12,000 1er avril 1985.13,000 1er avril 1986.14,500 1er avril 1987 .9,000 1er avril 1988.10,000 1er avril 1989.11,500 1er avril 1990.12,000 1er avril 1991.83,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $7,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, ct en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2011 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes suuf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1991 au montant dc 883,500 comprend un solde de $70,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, ct échéant comme suit: Table o} rédemption \u2014 $263,000 \u2014 20 years Year Capital April 1, 1972.$ 4,500 April 1, 1973.6,000 Aprill, 1974.5,500 Aprill, 1975.5,500 April 1, 1976 .6,500 Aprill, 1977.7,000 April 1, 1978 .8,000 Aprill, 1979.8,000 Aprill, 1980.8,000 April 1, 1981.9,000 Aprill, 1982 .9,500 Aprill, 1983.11,000 April 1,1984.12,000 Aprill, 1985.13,000 Aprill, 1986.14,500 Aprill, 1987 .9,000 April 1,1988.10,000 Aprill, 1989.11,500 April 1, 1990.12,000 Aprill, 1991.83,500 Moreover, only the following terms and conditions shall be considered: 1.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over to the tenth year.2.One- to 15-year serial bonds with the balance carried over to the fifteenth year.3.One- to 10-ycar serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.4.One- to 10-year serial bonds with the balance carried over 10-ycar for one part and 20-year fixed-term bonds for the other part.However, for the latter terms and conditions, the 20-year fixed-term bonds shall not be for an amount less than $7,500, and if greater than the latter amount, the surplus must comprise only one or several complete annual amortizations, taking into account the tables of redemptions appearing in this notice, and starting with the last years of maturities excluding the maturity of April 1, 2011 of the renewable part hereafter indicated.However, tenders shall be sent for one of the above methods of issue only and shall comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law.The maturity of April 1, 1991 in the amount of $83,500 includes a balance of $70,500 renewable for an additional 20-ycar period, and maturing as follows: Année Capital 1er avril 1992.$1,500 1er avril 1993.1,500 1er avril 1994.1,500 1er avril 1995.1,500 1er avril 1996.2,000 1er avril 1997.2,000 1er avril 1998.2,000 1er avril 1999 .2,500 1er avril 2000 .2,500 1er avril 2001.3,000 Year Capital April 1, 1992.$1,500 Aprill, 1993.\" 1,500 April 1,1994.1,500 Aprill, 1995.1,500 Aprill, 1996.2,000 April 1, 1997.2,000 April i; 1998 .2,000 April 1, 1999.2,500 Aprill, 2000.2,500 April 1,2001.3,000 2078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 1er avril 2002.$3,500 1er avril 2003.3,500 1er avril 2004.4,000 1er avril 2005.4,500 1er avril 2006.4,500 1er avril 2007 .5,000 1er avril 2008.5,500 1er avril 2009.6,000 1er avril 2010.6,500 1er avril 2011 .7,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, capital et intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Loretteville.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $83,500 ct seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté égal à 1% du montant de l'emprunt et devra spécifier si le prix olfert comprend ou ne comprend pas les intérêts courus sur les obligations au moment de leur livraison.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: B-76 \u2014 $1,800 \u2014 aqueduc, égouts; B-90 \u2014 $4,000 \u2014 camion incendie; IÎ-108 \u2014 $18,000 \u2014 voirie; B-115 \u2014 $7,500 \u2014 voirie; B-116 \u2014 315,600 \u2014 aqueduc, égouts; B-119 \u2014S4.500 \u2014 aqueduc, égouts; B-120 \u2014 S30.000 \u2014 aqueduc, égouts; B-121 \u2014 $24,500 \u2014 aqueduc, égouts; B-129 \u2014 $2,200 \u2014 aqueduc, égouts; B-130 \u2014 82,700 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; B-131 \u2014 81,100 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; B-132 \u2014 SI,100 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; B-133 \u2014 82,300 \u2014 voirie; B-134 \u2014 88,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; B-135 \u2014 81,000 \u2014 voirie; B-136 \u2014 32,200 \u2014 voirie; B-138 \u2014 S50.000 \u2014 augmentation du fonds de roulement; B-140 \u2014 S14.000 \u2014 travaux d'aménagement dc bureau ; B-141 \u2014 S4.500 \u2014 travaux dc la salle municipale; B-142 \u2014 S6.500 \u2014 travaux terrain de stationnement; B-143 \u2014 83,000 \u2014 électricité; B-144 \u2014 33,500 \u2014 aqueduc, égouts; B-145 \u2014 845,000 \u2014 travaux au garage municipal.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 15 mars 1971, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 220, boulevard Saint-Gérard, Bélair, comté de Portneuf, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bélair (Comté de Portneuf), ce 24 février 1971.¦ Le secrétaire-trésorier, Claude Grenier, Hôtel de ville, 220, boul.St-Gérard, Bélair, Comté de Portneuf, P.Q., Téléphone : 842-7184, code 418.«8933-0 April 1,2002.$3,500 Aprill, 2003 .3,500 Aprill, 2004.4,000 Aprill, 2005 .4,500 Aprill, 2006 .4,500 April 1, 2007 .5,000 Aprill, 2008 .5,500 Aprill, 2009.6,000 Aprill, 2010.6,500 April 1,2011.7,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Loretteville.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation if they are issued partly as 20-year fixcd-tcrm bonds for an amount greater than $83,500, and only this surplus will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the amount required to amortize the issue in accordance with the table of maturities appearing in this notice.Each, tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the issue and must specify whether interest accrued on the bonds to the date of their delivery is included or not in the price of the tender.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: B-76 \u2014 $1,800 \u2014 aqueduct, sewers; B-90 \u2014 $4,000 \u2014 fire truck; B-108 \u2014 $18,000 \u2014 roads; B-115 \u2014 S7.500 \u2014 roads; B-116 \u2014 S15.600 \u2014 aqueduct, sewers; B-119 \u2014 34,500 \u2014 aqueduct, sewers; B-120 \u2014 830,000 \u2014 aqueduct, sewers; B-121 \u2014 S24.500 \u2014 aqueduct, sewers; B-129 \u2014 S2.200 \u2014 aqueduct, sewers; B-130 \u2014 32,700 \u2014 aqueduct, sewers, roads; B-131 \u2014 SI,100 \u2014 aqueduct, sewers, roads; B-132 \u2014 $1,100 \u2014 aqueduct, sewers, roads; B-133 \u2014 $2,300 \u2014 roads; B-134 \u2014 SS.000 \u2014 aqueduct, sewers, roads; B-135 \u2014 81,000 \u2014 roads; B-136 \u2014 82,200 \u2014 roads; B-138 \u2014 S50.000 \u2014 increase of working capital; B-140 \u2014 314,000 \u2014 office planning works; B-141 \u2014 84,500 \u2014 municipal hall works; B-142 \u2014 S6.500 \u2014 parking ground works; B-143 \u2014 83,000 \u2014 electricity; B-144 \u2014 83,500 \u2014 aqueduct, sewers; B-145 \u2014 $45,000 \u2014 municipal garage works.The tenders shall be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, March 15, 1971, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 220 Saint-Gérard Boulevard, Bélair, county of Portneuf, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Békir (County of Portneuf), February 24, 1971.Claude Grenier, Secretary-Treasurer.Town Hall, 220 St-Gérard Boulevard, Bélair, County of Portneuf, P.Q., Telephone: 842-7184, code 418.38933 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 2079 Ministère du Travail et de la Department of Labour and Main-d'oeuvre Manpower Avis d'approbation dc règlements Automobile \u2014 Drummond Le ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets de convention collective (Chapitre 143, S.Q.1964, modifiée par le Chapitre 49, S.Q.1969), que les statuts du Comité paritaire dc l'industrie dc l'automobile du comté de Drummond, approuvés par l'arrêté en conseil numéro 2806 du 11 octobre 1967 ont été abrogés par l'arrêté en conseil numéro 774, du 24 février 1971.Le sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre.Québec, le 27 février 1971.38858-0 Notice of Approval of Regulations Automobile Industry \u2014 Drummond Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (S.Q.1964, chapter 143, amended by S.Q.1969, chapter 49), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the constitutions of the Parity Committee of the Automobile Industry of Drummond County, approved by Order in Council No.2806 of October 11, 1967 has been abrogated by Order in Council No.774 of February 24, 1971.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, February 27, 1971.38858-0 Avis d'abrogation de constitution et règlements Automobile \u2014 Mauricie Le ministre du Travail et dc la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions dc la Loi des décrets dc convention collective (Chapitre 143, S.Q.1964, modifiée par le chapitre 49, S.Q.1969), que la constitution et les règlements du Comité paritaire de l'automobile dc la Mauricie, déjà approuvés par l'arrêté en conseil numéro 3348 du 16 octobre 1968 ont été modifiés par l'arrêté en conseil numéro 775 du 24 février 1971.Le sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail ct de la Main-d'ocuvre.Québec, le 27 février 1971.38858-0 Avis de modification llobe \u2014 Province Le ministre du Travail ct dc la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que les parties contractantes à la convention collective dc travail relative à l'industrie dc la robe dans la province de Québec, rendue obligatoire par le décret numéro 3519 du 24 septembre 1940 et modifications, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation ct à la décision du lieutenant-gouverneur en conseil les modifications suivantes audit décret: 1° La partie de l'article I, (Champ d'application industriel), (A), du commencement jusqu'aux mots * ouvrés ou fabriqués dans la manufacture », sera remplacé par le suivant: Notice of Abrogation of Constitution and Regulations Automobile \u2014 Si.Maurice Valley Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (S.Q.1964, chapter 143, amended by S.Q.1969, chapter 49), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the constitution and regulations of the Automobile Parity Committee of the St.Maurice Valley, already approved by Order in Council No.3348 of October 16, 1968, have been amended by Order in Council number 775 of February 25, 1971.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, February 27, 1971.38858-o Notice of Amendment Dress Industry \u2014 Province Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (Revised Statutes of Québec 1964, chapter 143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the contracting parties to the collective labour agreement respecting the Dress Industry in the Province of Québec, rendered obligatory by Decree number 3519 of September 24,1940 and amendments, have petitioned him to submit to the Lieutenant-Governor in Council, for consideration and decision, the following amendments to the said decree: 1.That part of Section I, (Industrial jurisdiction), (A), from the beginning until the words \"worked or fabricated in the factory\", will be replaced by the following: 2080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, £7 février 1971, Vol.103, n° S « 1.Champ d'application industriel: (A) Le présent décret régit l'industrie de lu fabrication ou production complète ou partielle, pour toutes personnes du sexe féminin, dc tout genre ou catégorie de robes, blouses ct jupes dépareillées, ct tout vêtement y compris entr'au-tres: Ensembles, robes, robes du soir, vêtements ou costumes dc plage, dc bain, de jeux et de sport, pantalons longs, (slacks), pantalons dc ski ct couvre-tout de ski pour personnes du sexe féminin, quelle que soit la marque de commerce sous laquelle ils sont connus, blouses, plastrons, couvre-tout, sarraux, robes d'intérieur (brunch coats, dusters, housecoats), tabliers, kimonos, robes dc chambre ct uniformes, le tout dc quelque modèle ct description ct fait de matières dc toutes sortes ou natures que ce soit, naturelles ou artificielles et, sans changer la généralité de ce qui précède, dc matières tissées, tricotées, plastiques, synthétiques, en cuir et en feutre, le tout comprenant combinaisons et mélanges de n'importe lesquelles des matières précitées, le tout non assujetti aux décrets numéros 523 du 11 mui 1055 ct 711 du 30 avril 1963, dans leur teneur modifiée.Le décret s'upplique également ù toute purtie de tels vêtements qu'elle soit fabriquée séparément ou non.Les effets suivants sont expressément exclus: .a) Vêtements faits de.caoutchouc ou de tissu de caoutchouc; b) Blousons de ski, coupe-vent, jambières et habits \u2022 de neige pour enfants, faits de quelque tissu que ce soit; c) Robes de bain, kimonos et robes dc chambre faites de ratine (tissu éponge), édredon ou laine, flanelle ou autre matériel d'une pesanteur de 8 onces ou plus à la verge carrée; d) Vêtements pour bébés, enfunts et fillettes de toutes descriptions jusqu'à ct y compris l'ûge de six ans; e) Tabliers portés devant soi pour préserver ses vêtements ou servir d'ornements; i.quand les mêmes employés font toujours le même travail, au même endroit; ii.quund lu production est entièrement distincte ct séparée dc celle des autres vêtements ou parties de vêtements ou lingeries ouvrés ou fabriqués dans la manufacture.» 2° L'article I, (Champ d'application industriel), sera modifié en ajoutant le sous-paragraphe (D) suivant: « D) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent décret s'applique à tous les vêtements tricotés, tel que défini aux présentes, lorsque tels vêtements sont fabriqués de composants ou parties requérant l'une quelconque des opérations exécutées par les ouvriers des métiers définis à l'article III «lu présent décret.» La publication du présent avis ne rend pas ogliga-toircs les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date dc su publication dans la Gazelle officielle du Québec.\"1.Industrial jurisdiction: (A) This decree shall apply to the industry of manufacturing or producing completely or partially for all persons of the female sex, all types and styles of dresses, blouses and odd and separate skirts, and all garments analogous thereto and including but not limited to: Ensembles, gowns, beach clothes, bathing and swimming suits, pluy clothes, sport clothes, slacks, ski slacks, ski coveralls and trousers made for the female sex, by whatever trade name they may be known, blouses, vestees, smocks, brunch coats, hoovers, housecoats, dusters, aprons, kimonos, dressing gowns and uniforms, the whole of all styles and descriptions and made of material of any kind or nature whatsoever, whether natural or artificial; and without altering the generality of the foregoing of woven, knitted, plastic, synthetic, leather and felt materials, the whole including combinations or blends of any of the foregoing, the whole not falling within Orders in Council numbers 523 of May 11, 1955 and 711 of April 30, 1963, and amendments thereto.This decree likewise shall apply to the several parts of any of the aforesaid garments when manufactured in combination or scparutely us independent items.The following products are specifically excluded: (a) Wearing apparel made of rubber or rubber material; (b) Ski jackets, windbreakers, children's legging and snow suits, the whole made of any material whatsoever; (c) Bathrobes, kimonos and dressing gowns made of terry cloth, eiderdown or wool, flannel, or any other material of a weight of 8 ounces or more per square yard; (d) Infants', kiddies' und girls' wearing apparel of any description up to and including the age of six; (e) Aprons worn on the fore part of the body to preserve clothing or as ornaments; 1.when the same employees are always engaged in the same work, in the same place; ii.when the production is entirely distinct and separated from that of other garments or parts of garments or underclothing worked or fabricated in the factory.\" 2.Section I, (Irulustrial jurisdiction), will be amended by adding thereto the following sub-section CD) ; \"(D) Without limiting the generality of the foregoing, this decree shall apply to all knitted garments as herein defined when such garments arc made of components or parts which require any of the operations as performed by employees in the crafts defined in Section III of the present decree.\" Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Quebec Official Gazette. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2081 Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazelle officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail ct de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minislre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 27 février 1971.38858-0 Avis dc modification Alimentation \u2014 Montréal Le ministre du Travail ct dc la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143), que « L'Association des Magasins-Chaîne du Québec», lui a présenté une requête à l'effet d'être acceptée comme partie contractante au décret numéro 921 du 4 mai 1965, relatif au commerce dc l'alimentation au détail dans la région de Montréal.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, l'honorable ministre du Travail et de la Main-d'ocuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 27 février 1971.38858-o Avis d'approbation de règlements Automobile \u2014 Mauricie Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux paragraphes « g » et « A » de l'article 20 de la Loi des décrets de convention collective (Chapitre 143, S.Q., 1964 modifiée par le chapitre 49, S.Q.1969), que le règlement numéro 2, dont le texte suit, relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie a été approuvé par l'arrêté en conseil numéro 777 du 24 février 1971.Comité paritaire de, l'automobile de la Mauricie Règlement numéro 2 Tenue du registre \u2014 Rapport mensuel Tenue du registre: Le comité paritaire rend obligatoire pour tout employeur professionnel régi par le décret numéro 1704 During the thirty days following publication of this notice in the Québec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour and Manpowrw will consider objections which interested parties may wish to make.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower.Québec, February 27, 1971.38858-0 Notice of Amendment Retail Food Stores \u2014 Montreal Region Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (Revised Statutes of Québec 1964, chapter 143), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that L'Association des Magasins-Cliaine du Québec, have petitioned him for the purpose of being accepted as contracting party to Decree number 921 of May 4, 1965, respecting Retail Food Stores in the region of Montreal.Publication of this notice docs not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazette.During the thirty days following publication of this notice in the Quebec Official Gazette, the Honourable Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, February 27, 1971.38858-0 Notice of Approval of Regulations Automobile \u2014 St.Maurice Valley Pursuant to the provisions of subsections \"g\" and \"h\" of section 20 of the Collective Agreement Decrees Act (S.Q.1964, chapter 143, amended by S.Q.1969, chapter 49), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the following regulation number 2, respecting the keeping of the register and the monthly report of the Automobile Parity Committee of the St.Maurice Valley has been approved by Order in Council number 777 of February 24, 1971.Automobile Parity Committee of the St.Maurice Valley Regulation number 2 Keeping of a register \u2014 Monthly report Keeping of a register: The Parity Committee makes it obligatory for any professional employer governed by Decree number 1704 2082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n\" 9 du 6 juin 1968, publié dans la Gazelle officielle du Québec du 22 juin 1968 et/ou par le décret numéro 2535 du 20 septembre 1967, publié dans la Gazelle officielle du Québec du 7 octobre 1967, y compris toutes modifications ultérieures, la tenue d'un registre où sont indiqués les nom, prénoms, adresse ct numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, la qualification ou classification, l'heure précise à laquelle le travail a débuté, fut, selon le cas, interrompu, repris ct terminé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l'époque de paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l'application desdits décrets.Ce registre doit être gardé disponible à la place d'affaires de l'employeur.Rapport mensuel: Le comité paritaire oblige tout employeur professionnel régi par le décret numéro 1704 du 6 juin 1968, publié dans la Gazelle officielle du Québec du 22 juin 1968 et/ou par le décret numéro 2535 du 20 septembre 1967, publié dans la Gazelle officielle du Québec du 7 octobre 1967, y compris toutes modifications ultérieures, à lui transmettre, à son siège social, un rapport mensuel par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable qu'il désigne, sur lequel doivent être indiqués les nom, prénoms, adresse et numéro d'assurance sociale de chaque salarié à son emploi, la qualification ou classification, le nombre d'heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque mois, la nature de ce travail et le salaire payé.Ledit rapport doit être transmis au comité paritaire le ou avant le 15 de chaque mois ct doit couvrir le mois précédent.L'employeur professionnel doit demander au comité paritaire les formules nécessaires à la préparation et à la soumission dudit rapport.Tout employeur professionnel ayant sa place d'affaires dans le champ d'application territorial desdits décrets doit soumettre ce rapport, même.dans le cas ou aucun travail n'a été exécuté; le comité paritaire n'étant pas tenu d'établir une preuve quelconque de travail.Le sous-ministre, Robert Sauvé.Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, Québec, le 27 février 1971.38858-0 Avis d'approbation de règlements Automobile \u2014 Mauricie Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les_ présentes, conformément aux dispositions de la Loi des décrets de convention collective (Chapitre 143, S.Q.1964, modifiée par le chapitre 49, S.Q.1969), que le-règlement numéro 6, dont le texte suit, relatif aux certificats de qualification et de classification du Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie a été approuvé par l'arrêté en conseil numéro 778 du 24 février 1971.of June 6, 1968, published in the Québec Official Gazette of June 22, 1968 and/or by Decree number 2535 of September 20, 1967, published in the Québec Official Gazette of October 7, 1967, and all subsequent amendments, to keep a register in which are shown : the name, first names, address and Social Insurance number of each employee in his service, such employee's competency or classification the exact time work was begun and, as the case may be, interrupted, resumed and ceased each day, the nature of such work and the wage paid, with mention of the method and time of payment and all other information deemed useful in the application of the said decrees.Such register shall be available at the employer's place of business.Monthly report: The Parity Committee makes it obligatory for any professional employer governed by Decree number 1704 of June 6, 1968, published in the Quebec Official Gazette of June 22, 1968 and/or by Decree number 2535 of September 20, 1967, published in the Québec Official Gazette of October 7, 1967, and all subsequent amendments, to forward a written monthly report to the Committee's corporate seat.Such report is to be signed by himself, or by some responsible perron designated by him, and shall give: the name, first names, address and Social Insurance number of each employee in his service, the employee's competency or classification, the regular and overtime hours worked each month, the nature of such work and the wage paid.The said report shall be forwarded to the Parity Committee on or before the 15th of each month and shall cover the previous month.Professional employers shall ask the Parity Committee for the forms required to prepare and submit the said report.Any professional employer having his place of business within the territorial jurisdiction of the said decrees shall submit such report, even if no work has been carried out, as the Parity Committee is not obliged to give any proof of work.Robert Sauvé, Deputy Minister.Department of Labour and Manpower, Québec, February 27, 1971.38858 Notice of Approval of Regulations Automobile \u2014 St.Maurice Valley Pursuant to the provisions of the Collective Agreement Decrees Act (S.Q.1964, chapter 143, amended by S.Q.1969, chapter 49), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that the following Regulation No.6, respecting the competency and classification certificates of the Automobile Parity Committee of the St.Maurice Valley, has been approved by Order in Council No.778 of February 24, 1971. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.108, No.9 2083 Comité paritaire de l'automobile de la Mauricie Règlement numéro 6 Certificats de qualification et de classification Article 1.Certificat de qualification: a) Conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi des décrets de convention collective (S.Q.1964, chapitre 143, modifiée par le chapitre 49, S.Q.1969), le Comité paritaire rend le certificat de qualification obligatoire, dans tout le champ d'application territorial des décrets numéros 1704 du 6 juin 1968 et 2535 du 20 septembre 1967, y compris toutes modifications ultérieures, et ce, pour tous les salariés qui, assujettis auxdits décrets, exercent les métiers suivants: Décret numéro 1704: Carossier-peintre, mécanicien.Décret numéro 2585: Carossier-peintre, mécanicien, machiniste, électricien, aligneur dc roues.Toutefois, ce règlement ne s'applique pas aux salariés régis par l'article 36 de la Loi des décrets de convention collective.b) Le comité paritaire peut exiger à titre d'honoraires, une somme n'excédant pas §2 pour l'examen d'un compagnon (ouvrier qualifié) et SI pour l'examen d'un apprenti.c) Le Comité paritaire reconnaît comme valides, les certificats de qualification et/ou classification délivrés par l'cx-comité paritaire de l'industrie de l'automobile du comté de Drummond antérieurement chargé d'assurer la surveillance et l'observance du décret numéro 2535 du 20 septembre 1967._ d) Le salarié détenteur d'un certificat de qualification et/ou de classification délivré par un comité paritaire autre que celui dc l'automobile de la Mauricie et/ou de l'industrie de l'automobile du comté de Drummond, doit faire valider son certificat par le comité paritaire, avant de pouvoir exercer dans le champ d'application territorial des décrets numéros 1704 du 6 juin 1968 et 2535 du 20 septembre 1967, y compris toutes modifications ultérieures, le métier ou l'occupation pour lequel il est qualifié ou classifié.e) Le pourcentage requis par le comité paritaire pour l'obtention d'un certificat de qualification est le suivant: Classe « C » : 60% Classe « B »: 70% Classe « A » : 85% Article 2.Bureau d'examinateurs: Le comité paritaire crée un bureau d'examinateurs composé de quatre (4) membres dont deux (2) représentent les parties patronales et deux (2) les parties syndicales, pour déterminer la qualification des salariés et leur délivrer les certificats concernés.Ces membres se désignent entre eux un président.Article 3.Terme d'office: Le terme des membres du bureau d'examinateurs commence à la date de l'approbation du présent règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et se Automobile Parity Committee of the St.Maurice Valley Regulation number 6 Competency and classification certificates Section 1.Competency certificate: (a) Pursuant to the provisions of section 25 of the Collective Agreement Decrees Act (S.Q.1964, chapter 143, amended by S.Q.1969, chapter 49), the Parity Committee makes the competency certificate compulsory within the entire territorial jurisdiction of Decrees No.1704 of June 6, 1968 and No.2535 of September 20, 1967, including all further amendments, for all employees governed by the said decrees who ply the following trades: Decree No.1704: Bodyman-painter, mechanic.Decree No.2535: Bodyman-painter, mechanic, machine operator, electrician, alignment technician.This regulation, however, docs not apply to employees governed by section 36 of the Collective Agreement Decrees Act.(b) The Parity Committee may ask fees not to exceed $2 for the examination of a journeyman (skilled workman) and SI for the examination of an apprentice.(c) The Parity Committee shall recognize the validity of competency and/or classification certificates issued by the former Parity Committee of the Automobile Industry of Drummond County which was previously entrusted with the supervision and enforcement of Decree No.2535 of September 20, 1967.( tiff, es ROLLAND CABANA, I defendant, LUCIEN MONTFILS, mis en cause.\"A certain plot of land of irregular dimensions located on the north side of Cowic Street (formerly Canaan road) in the city of Granby, measuring approximately one hundred and twelve feet (112') in width along the said Cowie Street, that is on its southern boundary, one hundred and ten feet (110') in width towards the back, that is on its northern boundary, two hundred and twenty-eight feet (228') in depth on its eastern boundary, and two hundred and five feet (205') in depth on its western boundary, known and designated as being the south-western corner of lot number six hundred and twenty-nine (s.-w.corner 629) on the official plan and reference book of the cadastre of the township of Granby, with buildings thereon erected.The said plot of land is measured from a point on the northern side of Cowie Street, being the southwestern corner of the said lot No.629; from there towards the north, along the western side of the said lot, a distance of two hundred and five feet (205'); from there, turning at right angles towards the east, a distance of one hundred and ten feet (110'); from there, turning at right angles towards the south, an approximate distance of two hundred and twenty-eight feet (228'), that is up to the northern side of Cowie Street; from there, turning at a sharp angle towards the west, skirting the northern side of the said Cowie Street, an approximate distance of one hundred and twelve feet (112'), that is up to the point of departure.The said plot of land is bounded as follows: towards the north and the cast, by other parts of the said lot No.629 belonging to .or representatives; to the south by Cowie Street, and towards the west by the dividing line between lots Nos 629 and 630 of the same cadastre.The whole in English measurements more or less.\" To be sold at the Registry Office of Shefford, at Waterloo, district of Bedford, WEDNESDAY, the THIRTY-FIRST day of MARCH, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Antonin Bouhassa, Sheriff's Office, Sheriff.Cowansville, February 17, 1971.38918 DRUMMOND Canada \u2014 Province of Québec District of Drummond Superior Court: ( T A SOCIÉTÉ DES ARTISANS, Writ No.2061a a corporation legally incorpora-v ted, having its head office in the city 2090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 ville et district dc Montréal, demanderesse vs ERNEST LAFERRIÈRE, employé d'usine, résidant au numéro 860, de la lOSe Avenue, à Drummondville-Sud district dc Drummond, défendeur ct Dame MARIE ROSE BINETTE-LAFERRIÈRE, mise en cause.« Un lot ou emplacement connu et désigné aux plan et livre dc renvoi officiels du cadastre du canton dc Wickham, comté de Drummond, sous le numéro cent soixante-sept de la subdivision officielle du lot numéro cent quatre (10-1-167 Wickham), avec bâtisses dessus construites.» Pour cire vendu au bureau de la division d'enregistrement dc Drummond, district de Drummond, Palais de Justice, Drummondville, JEUDI, le PREMIER jour d'AVRIL 1971, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Stephen Dolan.Drummondville, ce 19 février 1971.38919-o MONTMAGNY Fieri Facias de Terris District de Beaucc Cour Supérieure, f p II ARLES CHASSÉ & FILS No 26-720.< ' LTÉE, corporation légale-v.ment constituée ct ayant sa place d'affaires à Ste-Maric de Beauce, demanderesse, vs LUCIEN LANGEVIN, Ste-Euphémic, comté de Montmagny, défendeur.« Une ferme contenant en superficie 90 à 100 acres plus ou moins,' ayant toute la longueur du lot sur la profondeur qu'il y a depuis le chemin du Roi au sud à aller au nord jusqu'au chemin de fer Transcontinental ct est connu comme partie du lot No 6 du 1er rang sud-est du canton Armagh, partie annexée au canton Montminy.À distraire les parties vendues au ministère de la Voirie ».Pour être vendu au bureau du shérif de Montmagny, district de Montmagny, le CINQUIÈME jour d'AVRIL 1971, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif, Bureau du Shérif, Jean-Paul Tremblay.Montmagny, 19 février 1971.38920-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal (T A BANQUE DE NOUVELLE-No 795-846.< ^ ECOSSE, une corporation légale- v ment constituée ayant son siège social à Halifax, Nouvelle-Ecosse et une succursale au Centre d'Achats Laval, Laval, district dc Montréal, demanderesse, vs ANDRÉ LAVOIE, résidant ct domicilié à Ste-Dorothée, Laval, (53 Bord de l'Eau), district de Montréal, défendeur.and district of Montreal, plaintiff, vs ERNEST LAFERRIÈRE, plant employee, residing at 860,108th Avenue, Drummondville-South, district of Drummond, defendant, and Mrs.MARIE ROSE BINETTE-LAFERRIÈRE, mise en cause.\"A lot or emplacement known and designated on the official plan and in the book of reference of the cadastre of the township of Wickham, county of Drummond, under number one hundred and sixty-' seven of the official subdivision of lot number one hundred and four (104-167 Wickham), with buildings built thereon.\" To be sold at the office of the Drummond Registration Division, district of Drummond, Court House, Drummondville, on THURSDAY, the FIRST day of APRIL, 1971, at TEN o'clock in the forenoon.Stephen Dolan, Sheriff's Office, Sheriff.Drummondville, February 19, 1971.38919 MONTMAGNY Fieri Facias de Terris District of Beauce Superior Court, ( pHARLES CHASSÉ & FILS No.26-720.< v-* LTÉE, a corporation legally v incorporated and having its place of business at Ste-Marie de Beauce, plaintiff; vs LUCIEN LANGEVIN, Ste-Euphémie, county of Montmagny, defendant.\"A farm with an area of 90 to 100 acres, more or less, consisting of the entire length of the lot by the depth existing from the King's Road, south to north, to the Transcontinental Railway and known as part of lot No.6 of the 1st southeast range of the township of Armagh, this part annexed to the township of Montminy.To withdraw the parts sold to the Department of Roads.\" .To be sold at the office of the Sheriff of Montmagny, district of Montmagny, on the FIFTH day of APRIL, 1971, at THREE o'clock.Jean-Paul Tremblay, Sheriff's Office, Sheriff.Montmagny, February 19, 1971.38920 MONTREAL Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal / \"DANK OF NOVA SCOTIA, a corpo-No.795-846.^ *\u2022* ration legally incorporated having t its head office in Halifax, Nova Scotia, and a branch office at the Laval Shopping Centre, Laval, district of Montreal, plaintiff vs ANDRÉ LAVOIE, residing at Ste-Dorothée, Laval (53 Bord de l'Eau), district of Montreal, defendant. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2091 « Un emplacement situé à Laval (Ste-Dorothée), et composé: 1° d'une partie du lot originaire numéro six (ptie 6) aux plan et livre dc renvoi officiels de la paroisse de Ste-Dorothée, mesurant soixante-quinze pieds (75') de largeur par une profondeur dc deux cent quatre-vingt-huit pieds (288') dans la ligne nord-est, ct deux cent quatre-vingts pieds (280') dans la ligne sud-ouest, et bornée comme suit: au sud-est par le chemin public, au sud-ouest par une partie du lot originaire numéro 7, au nord-ouest par une autre partie dudit lot originaire No 6 ct au nord-est par une partie du lot originaire No 2.2° d'une partie du lot originaire numéro sept (ptie 7) auxdits plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse de Sainte-Dorothée, mesurant soixante-quinze (75') de largeur par une profondeur de deux cent quatre-vingts pieds (2S0') dans la ligne nord-est, et deux cent quarante-cinq pieds (245') dans la ligne sud-ouest, ct bornée comme suit: au sud-est par ledit chemin public, au sud-ouest par une partie du lot originaire No 8, au nord-ouest par le résidu dudit lot No 7,_ et au nord-est par une partie du lot originaire No 6.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble mais sans garantie de mesure précise.Avec toutes les constructions y érigées et notamment une maison portant le numéro 53, rang du Bord dc l'Eau.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155 boulevard Je Me Souviens, à Laval, ville dc Laval, le PREMIER jour d'AVRIL 1971, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 17 février 1971.38927-o \"A site situated at Laval (Ste-Dorothée), and made up as follows: 1.Of part of the original lot No.six (part 6) on the official plan and reference book of the parish of Ste-Dorothée, measuring seventy-five feet (75') in width by two hundred and eighty-eight feet in depth along the northeastern line, and two hundred and eighty feet (280') along the southwestern line, and bounded as follows: towards the southeast by the said public road, towards the southwest by part of the original lot No.7, towards the northwest by another part of the said original lot No.6 and towards the northeast by part of the original lot.No.2.2.Of part of the original lot No.seven (part 7) on the said official plan and reference book of the parish of Ste-Dorothée, measuring seventy-five feet (75') in width by two hundred and eighty feet (2S0') in depth along the northeastern line, and two hundred and forty-five feet (245') along the southwestern line, and bounded as follows: towards the southeast by the said public road, towards the southwest by part of the original lot No.8, towards the northwest by the remainder of the said lot No.7, and towards the northeast by part of the original lot No.6.As the whole stands at present with all the active, passive, apparent and unapparcnt servitudes attached to the said immovable property but without any guarantee of precise measurements.With all the constructions erected thereon and in particular a house bearing civic number 53, Rang du Bord de l'Eau.\" To be sold at the Registry Office of the county of Laval, 155 Je Me Souviens Boulevard, at Laval, City of Laval, the FIRST day of APRIL, 1971, at ELEVEN a.m.Office of the Sheriff, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 17, 1971.38927 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal L A LBERT VIAU, des cité et district No 764-219.S de Montréal, demandeur, vs K FRANCO alias GIUSEPPE CAMMI-SANO et CAMISANO, des cité et district de Montréal, défendeur.Désignation « Un emplacement composé du numéro 187 de la subdivision du lot originaire 421, en la paroisse du Sault-aux-Récollets avec les bâtisses dessus érigées, aux numéros civiques 5885, 5887 et 5889 rue Hautbois à St-Léonard.» Pour être vendu au bureau du protonotaire, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, en la ville de Montréal, le PREMIER jour d'AVRIL 1971, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 17 février 1971.38929-o Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C A LBERT VIAU, of the city and dis-No.764-219.\\ trict of Montreal, plaintiff, vs I FRANCO alias GIUSEPPE CAMMI-SANO et CAMISANO, of the city and district of Montreal, defendant.Description \"A site bearing number 187 of the subdivision of the original lot number 421 in the parish of Sault-aux-Récollets with the buildings thereon erected, bearing civic numbers 5885, 5887 and 5889 Hautbois Street at St-Léonard.\" To be sold at the Office of the Prothonotary, Room #129, Old Court House, in the city of Montreal, the FIUST day of APRIL, 1971, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin.Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 17, 197i.38929 2092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 février 1971, 103' année, n° 9 Fieri Facias de Terris Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( CLAUDE LAPERRIÈRE ET AL., No 796-604.< v\u2014' demeurant à St-Basilc-le-Grand, t PIERRE HOGUE, psychologue des cité et district dc Montréal, FERNAND BLAIS, courtier d'assurance, des cité ct district dc Montréal, G.GRATTON LTÉE, corps politique dûment ct légalement constitué par lettres patentes scion la première partie dc la Loi ties compagnies tlu Québec, demandeurs, vs Dame GABRIELLE BENOIT, du numéro 3213 rue .larry est, dans les cité ct district de Montréal, défenderesse.Désignation < De la partie nord-est du lot numéro mille deux cent cinquante-six de la subdivision du lot originaire numéro trois cent quarante-trois (343-1256) des plan ct.livre dc renvoi tlu cadastre officiel dc la paroisse tlu Sault-au-Récollct, bornée en front vers le sud-est par le chemin St-Michcl, en arrière vers le nord-ouest par un mille, connue sous le numéro 343-1254, d'un côté vers le sud-ouest par le résidu dudit lot numéro 1256, et de l'autre, côté vers le nord-est, par le lot numéro 343-1257, ci-après et en second lieu tlécrit mesurant en largeur treize pieds, (13'), en profondeur quatre-vingt-dix pieds (90').De tout le lot numéro mille deux cent cinquante-sept dc la subdivision dudit lot originaire numéro trois cent quarante-trois (343-1257) mesurant en largeur vingt-trois (23'), et en profondeur quatre-vingt-dix pieds (90').Mesures anglaises ct plus ou moins.Avec bâtisses dessus construites portant les numéros civiques 3213 et 3215 rue Jarry est, ù Montréal.» Pour être vendu au bureau du protonotairc, chambre #129, au Vieux Palais de Justice, en la ville tic Montréal, le TRENTE ET UNIÈME jour dc MARS 1971, à DEUX heures dc l'après-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 17 février 1971.38928-0 Fieri Facias de Bonis dc Terris Cour Municipale \u2014 District de Montréal (TA VILLE DE WESTMOUNT, No 870.s '-J corporation municipale, ayant son t siège social à l'Hôtel de Ville, dans la ville de Westmount, dans le district tie Montréal, demanderesse ; contre WILLIAM LIEBER, gentilhomme, domicilié et résidant au 98, rue Columbia, thins la ville de Westmount, dans le district de Montréal, défendeur.« Un emplacement donnant sur l'avenue Columbia, dans la ville de Westmount, se composant comme suit: 1.De la partie sud-est, d'une largeur tie huit pieds de la subdivision trois cent six de la subdivision tie plan dûment faite ct enregistrée du lot numéro neuf cent quarante et un (No 941-P.S.E.306) aux plan et Fieri Facias de Terris Superior Court \u2014 District of Montreal C /\"\"1LAUDE LAPERRIÈRE ET AL., No.796-604.< residing at St-Basilc-le-Grand, I.PIERRE HOGUE, psychologist of the city und district of Montreal, FERNAND BLAIS, insurance broker of the city and district of Montreal, C.GRATTON LTÉE, botly politic duly antl legally incorporated by letters patent untler Part I of the Québec Companies Act, plaintiffs, vs Dame GABRIEL-LE BENOIT, of number 3213 Jarry Street East, in the city antl district of Montreal, defendant.Description \"From the northeastern part of lot number one thousand two hundred antl fifty-six of the subdivision of the original lot number three hundred and forty-three (343-1256) on the plan and book of reference of the official cadastre for the parish of Sault-au-Récollet, bounded in front towards the southeast by St-Michel Roatl, in the rear towards the northwest by a \"mille\", known under number 343-1254, on the one side towards the, southwest by the remainder of the said lot number 1256 antl on the other sitlc towards the northeast by lot number 343-1257, described hereafter in second place, measuring thirteen fect (13') in width, in depth ninety feet (90').Of the entire lot number one thousand two hundred and fifty-seven of the subdivision of the said original lot number three hundred and forty-three (343-1257) measuring iu width twentv-thrcc feet (23'), and in depth ninety feet (90').English measurements more or less.With the buildings erected thereon bearing civic numbers 3213 and 3215 Jarry Street East, in Montreal.\" To be sold at the Office of the Prothonotary, Room #129, in the Old Court House, in the city of Montreal, the THIRTY-FIRST day of MARCH, 1971, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, February 17, 1971.38928 Fieri Facias de Bonis et de Terris Municipal Court \u2014 District of Montreal C rT,HE CITY OF WESTMOUNT, a No.870.\\ *\u2022 municipal corporation, having v its head office at the City Hall, in the city of Westmount, in the district of Montreal, plaintiff, vs WILLIAM LIEBER, gentleman domiciled and residing at 98 Columbia Street, in the city of West-mount, in the district of Montreal, defendant.\"An emplacement fronting on Columbia Avenue in the city of Westmount, composed as follows: (1) Of the southeast part containing eight feet in width of subdivision three hundred and six on the subdivision plan duly made and filed of lot number nine hundred and forty-one (No.941-S.E.Pt.306) on QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 27, 1971, Vol.103, No.9 2093 livre
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.