Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 15 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1972-01-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" OFF A11E8 G3/ nee No 2 Ex.2 4 ?91 IUEBEI nUEBEr kiette officielle à Quebec QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE Partie I: avis juridiques Partie H: lois et règlements (Voir sommaire en dernière page) Part I: Juridical notices Part H: Laws and Regulations (Refer to the last page for summary) Québec, samedi 15 janvier 1972 Règlements 1° Adresser toute correspondance à l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec.2° Fournir le texte de l'annonce dans les deux langues officielles.Lorsque celle-ci est envoyée dans une seule langue la traduction en est faite aux frais des intéressés, d'après le tarif officiel.38 Indiquer le nombre d'insertions.4° Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.Québec, Saturday, January 15, 1972 Rules 1.Address all communications to The Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec.2.Advertisers should submit all copy in both official languages, otherwise they will be charged for translation at official rates.3.Specify the number of insertions.4.Advertisements are payable in advance at rates set forth below, except when they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, failing which further insertions will be automatically cancelled without prejudice to The Québec Official Publisher, and any overpayment refunded.L'Éditeur officiel du Québec, roch lefebvre, Québec Officiai PMieher 92 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972,10k' année, n° 2 58 L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables d'avance.6° Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des Finances.7° La Gazelle officielle du Québec est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder ia publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.8° Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.9° Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.Tarif des annonces, abonnements, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $4 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement: du 1er janvier au 31 décembre $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante : Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; la deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Rock Lefebvre.Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 avril 1969 43892 \u2014 l-52-o 5.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.6.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance.7.The Québec Official Gazette is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements for publication must reach The Québec Official Publisher, not later than Wednesday, noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a later edition.Moreover, The Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.8.Any request for cancellation nr refund is subject to the provisions of article 7.9.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify The Québec Official Publisher, before the second insertion, in order to avoid costly duplication.Advertising, Rates, Subscriptions, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version, (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular matter (lists of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $4 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods: From January 1st to December 31st, $20; April 1st to December 31st, $15 and Julv 1st to December 31st, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertion.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by The Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Booh Lefebvre, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, April 30, 1969 43892 \u2014 l-52-o Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n ° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10i, No.g 93 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Compagnies dissoutes Companies Dissolved Ameublement Thetford inc.Thctford Furniture Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Ameublement Thetford inc.\u2014 Thetford Furniture Inc.», constituée en corporation le 14 décembre 1965, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Roca Rioux.43904-o 5481-65 Dirkdale Agencies Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Birk-dale Agencies Inc.», constituée en corporation le 6 février 1961, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 10575-61 Blocs de Ciment Rouville inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de < Blocs de Ciment Rouville inc.», constituée en corporation le 5 mars 1962, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 10623-62 British Holdings Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « British Holdings Limited », constituée en corporation le 11 octobre 1944, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 4771-44 Brite Home Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Brite Home Construction Inc.», constituée en corporation le 27 octobre 1964, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 4693-64 Ameublement Thetford inc.Thetford Furniture Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Ameublement Thetford inc.\u2014 Thetford Furniture Inc.\", incorporated on December 14, 1965.Roch Rioux, Director nf the.Companies Service.43904 5481-65 Birkdale Agencies Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Birkdale Agencies Inc.\", incorporated on February 6, 1961.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.10575-61 Blocs de Ciment Rouville inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Blocs de Ciment Rouville inc.\", incorporated on March 5, 1962.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 10623-62 British Holdings Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"British Holdings Limited\", incorporated on October 11, 1944.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.4771-44 43904 43904 Brite Home Construction Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Brite Home Construction Inc.\", incorporated on October 27, 1964.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 4693-64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 197S, 101' année, n° S Combustion Utilities Corp.of Québec Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Combustion Utilities Corp.of Québec », constituée en corporation le 31 janvier 1945, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 1728-45 Combustion Utilities Corp.of Québec Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Combustion Utilities Corp.of Québec\", incorporated on January 31, 1945.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 1728-45 Commercial & Technical Computer Services (Québec) Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Commercial & Technical Computer Services (Québec) Limited», constituée en corporation le 28 juin 1965, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 2745-65 Commercial & Technical Computer Services (Québec) Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Commercial & Technical Computer Services (Québec) Limited\", incorporated on June 28, 1965.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 2745-65 La Compagnie de Placements d'Ibcrville limitée La Compagnie de Placements d'Ibcrville limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « La Compagnie de Placements d'Iberville limitée », constituée en corporation le 29 juin 1946, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.43904-o 4574-46 La Compagnie de Prêts Régionale Itée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « La Compagnie de Prêts Régionale ltée », constituée en corporation le 18 janvier 1966, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 225-66 Créations Charmantes inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Créations Charmantes inc.», constituée en corporation le 1er mars 1967, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 897-67 Dorchester Transport U.S.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Dor- Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, pf the charter of \"La Compagnie de Placements d'Iberville limitée\", incorporated on June 29, 1946.Roch Rioux, Director of the Companies Service.43904 4574-46 La Compagnie de Prêts Régionale ltée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"La Compagnie de Prêts Régionale ltée\", incorporated on January 18, 1966.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 225-66 Créations Charmantes inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Créations Charmantes inc.\"! incorporated on March 1, 1967.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 897-67 Dorchester Transport U.S.Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10i, No.2 95 Chester Transport U.S.Inc.», constituée en corporation le 2 mars 1970, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 1092-70 Erie Service & Equipment Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Erie Service & Equipment Ltd.», constituée en corporation le 29 juillet 1963, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 2827-63 as of December 30, 1971, of the charter of \"Dorchester Transport U.S.Inc.\", incorporated on March 2, 1970.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 1092-70 Erie Service & Equipment Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Erie Service & Equipment Ltd.\", incorporated on July 29, 1963.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 2827-63 Charles Goodfellow Lumber Company Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Charles Goodfellow Lumber Company Ltd.», constituée en corporation le 5 décembre 1961, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 13108-57 J.A.Kirouac limitée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « J.A.Kirouac limitée », constituée en corporation le 2 juillet 1925, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 1194-25 Loranger Construction Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Loranger Construction Inc.», constituée en corporation le 20 février 1962, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.43904-o 10756-62 Manny Realty Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Manny Realty Inc.», constituée en corporation le 29 juin 1953.à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 13386-53 Modem Trading Limited Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des Charles Goodfellow Lumber Company Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Charles Goodfellow- Lumber Company Ltd.\", incorporated on December 5, 1961.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 , 13108-57 J.A.Kirouac limitée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"J.A.Kirouac limitée », incorporated on July 2, 1925.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 1194-25 Loranger Construction Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Loranger Construction Inc.\", incorporated on February 20, 1962.Roch Rioux, Director of the Companies Service.43904 10756-62 Manny Realty Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Manny Realty Inc.\", incorporated on June 29, 1953.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 13386-53 Modern Trading Limited Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and 96 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101- année, n° 2 compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Modern Trading Limited », constituée en corporation le 10 décembre 1948, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.7763-48 43904-o A.B.Ostiguy limitée Le ministre des institutions financières, compa'gnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « A.B.Ostiguy limitée », constituée en corporation le 1er septembre 1959, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.14370-59 43904-o Thérèse Picard inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Thérèse Picard inc.», constituée en corporation le 17 avril 1968, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 1648-68 Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Modern Trading Limited\", incorporated on December 10, 1948.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.7763-48 43904 A.B.Ostiguy limitée Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"A.B.Ostiguy limitée\", incorporated on September 1, 1959.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 14370-59 Thérèse Picard inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives lias been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Thérèse Picard inc.\", incorporated on April 17, 1968.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 1648-68 Restaurant les Rouets de Lare inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Restaurant les Rouets de Lare inc.», constituée en corporation le 20 février 1970, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.43904-o 1553-70 Restaurant les Rouets de Lare inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Restaurant les Rouets de Lare inc.\", incorporated on February 20, 1970.Rocu Rioux, Director of the Companies Service.43904 1553-70 St.Maurice Waste Paper & Metal Co.Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « St.Maurice Waste Paper & Metal Co.Inc.», constituée en corporation le 14 novembre 1949, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 8433-49 Shanedling Company Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Shanedling Company Ltd.», constituée en corporation le 5 mai 1967, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 1988-67 St.Maurice Waste Paper & Metal Co.Inc.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"St.Maurice Waste Paper & Metal Co.Inc.\", incorporated on November 14, 1949.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 8433.49 Shanedling Company Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies ' and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Shanedling Company Ltd.\", incorporated on May 5, 1967.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service 43904 1988;67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 197£, Vol.m.No.S 97 Tri City Investments Corp.Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de « Tri City Investments Corp.Ltd.», constituée en corporation le 2 novembre 1966, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-o 4471-66 United Textiles Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de charte de \" United Textiles Ltd.», constituée en corporation le 17 août 1961, à compter du 30 décembre 1971.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43904-q 13890-61 Tri City Investments Corp.Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"Tri City Investments Corp.Ltd.\", incorporated on November 2, 1966.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 4471-66 United Textiles Ltd.Notice is given that, under the Companies Act, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has been pleased to accept the surrender, as of December 30, 1971, of the charter of \"United Textiles Ltd.\", incorporated on August 17, 1961.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43904 13890-61 Ventes pour taxes Sales for taxes Municipalité du comté de Beauce Je soussigné, Héliodore Rodrigue, secrétaire-trésorier du Conseil municipal du comté de Beauce, donne par les présentes avis public que les terres ou immeubles ci-dessous mentionnés seront vendus, par encan public, à Beauceville-Est, lieu où se tiennent les sessions du Conseil de comté, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi pour les cotisations et charges dues aux municipalités ci-dessous mentionnées, sur les divers lots plus bas désignés, à moins qu'elles ne soient payées, avec les frais, avant le jour ci-dessus indiqué.Municipality of the county of Beauce I undersigned, Héliodore Rodrigue, Secretary-Treasurer of the Municipal Council for the county of Beauce, give public notice that the lands or real estates hereinafter mentioned, will be sold by public auction at Beauceville-East, at the ordinary place of the sitting of the county council, on the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the asses-ments and charges due to the municipalities hereinafter mentioned upon the several lots hereinafter described, unless the same be paid, with costs, before the day of the sale aforesaid.Corporation municipale de St-Victor de Tring \u2014 Municipal corporation of St-Victor de Tring Propriétaires\tRang\tNuméro cadastre\tTaxes munie.\tTaxes BCOl.Total School taxes Owners\tRange\tCadastral number\tMunie, taxes\t \t.Ill\tP.408.\t$ 2.17\t$ 2.60 $ 4.77 \t\t\t\t Municipalité scolaire de l'Assomption \u2014 School municipality of l'Assomption Guay, Onésime.P.612.$ 233.05 $ 335.40 $ 668.45 Municipalité du village de St-Thcophile \u2014 Municipality of the village of St-Théophile Jacques, Athanase, St-Léon P.69.* 6.76 $ 19.69 $ 26.44 98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 101' année, n° 2 Municipalité du village Linière \u2014 Municipality of the village of Liniere \t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaires\tRang Numéro cadastre\tmunie.\tbcoI.\tTotal Owners\tRange Cadastral number\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxes\ttaxes\t Drouin, Germain, Aubin de l'isle.P.43.$ 35.90 * 60.45 % 96.35 Corporation de la paroisse de St-Honoré \u2014 Corporation of the parish of St-Honoré Champagne, Jean-Claude.IX P.17C-18AB & 21AB.t 365.17 S 568.95 934.12 Corporation scolaire de Beauceville \u2014 School corporation of Beauceville Roy, Martin (Wilfrid).Poulin, Mme Gaétan, a/s Curateur Public.Hôtel Royal, a/s Léandre Bernard.Bernard Léandre,.P.1530.908-09-10-11.2322-1-2, 110-2-1, 117-1-1, 120-2-133, 114-1.1627-118-2-1.8 158.78 2.360.42 40.54 372.52 3,858.57 740.70 40.54 531.30 9,218.99 740.70 Municipalité du village de St-Victor\u2014 Municipality of the village of St-Victor Cloutier, Maurice.Jolicoeur, Jean-Raymond.P.361.P.226.% 225.61 S 331.52 28.84 23.40 i 254.45 354.92 Municipalité scolaire de St-Honoré \u2014 School municipality of St-Honoré Patry, Henri-Louis.8 21B.S 442.12 t 442.12 Commission scolaire de S.-C.-de-Jésus \u2014 School commission of S.-C.-de-Jésus Suce.Louis Tardif.6 14B.$ 115.90 S 71.38 S 187.28 Commission scolaire de St-Côme \u2014 School commission of St-Côme Crevicto Limitée, 1, Aubin de l'isle.Lepage.Benoit.4, sec.B P.58A-B.P.13____ 233.74 S 265.09 11.10 11.10 Donné à Beauceville, ce 4 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 43911-2-2-0 Héliodore Rodrigue.Municipalité du comté de Richmond Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Me Camille Dupuis, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Richmond, que les propriétés ci-après décrites seront vendues à l'enchère, au lieu ordinaire des séances du Conseil, à Richmond, Que., au bureau du soussigné, le JEUDI, le NEUVIÈME jour du mois de MARS, mil neuf cent soixante-douze (1972), à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, intérêts et les frais, plus les frais encourus subséquemment, à Given at Beauceville, January 4, 1971.Héliodore Rodrigue, 4391 l-2-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Richmond Public notice is hereby given by the undersigned Me Camille Dupuis, Secretary-Treasurer of the municipality of the county of Richmond, that the immoveable property hereinafter described, will be sold by public auction, at the ordinary place of the meetings of the Council, at Richmond, Que., at the office of the under signed, on THURSDAY, the NINTH day of the month of MARCH, nineteen hundred and seventy-two (1972), at TEN o'clock in the morning, for the payment of municipal and school taxes, with the QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 1972, Vol.10k, No.2 09 moins que lcsdites taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.interest and costs, plus the costs subsequently incurred, unless the said taxes, interest and costs are paid before the sale.Canton de Cleveland \u2014 Township of Cleveland Propriétaire Owner Désignation Description Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Bachand, Gilles.Cloutier, Bertrand.Fleury, Mme Camille.Fowler, Ralph.Maurice, Conrad.Maurice, Conrad & Léandre.Simoneau, Paul.Plante, Marcel.Pt.17-A, Rang 12.* 18.20 28-D, Pt.28-A, Rang 14.7.10 26-A-17, Rang 10.17.90 11-A, Pt.11-B, Rang 13.46.60 Pt.14-F, Rang 15.8.95 Pt.22-D, Rang 9.44.15 Pts.13-A.Pt.14-C, 13-C, 14-B, 141.10 Rang 15.Lots 9-B & 9-C, Rang 9.9.55 $ 255.18 18.20 7.10 17.90 301.78 8.95 44.15 141.10 9.55 Canton de Melbourne \u2014 Township of Melbourne Boulanger.Denis.Pts.1-A, 1-C, 1-D, Rang 6.Lemieux, Richard.Lots 25-A, 25-C, Rang 7 Lots 25-A, Pt.26-A, Rang 8.Courchesne, Mme Noélla.Lot 12-18, Pt.12-19, Rang 8.17.66 37.96 105.95 43.84 $ 61.50 37.96 105.95 Municipalité d'Ulverton \u2014 Municipality of Ulverton Taylor, Bruce.Viger, Armand.Davies, John.Masters, Mme Arthur.Simpson, Estate.Veillon, Pierre.Lot 303.S 64.83 Lot 204 & Pt.295.13.20 Pt.532.14.35 Lot 281.25.00 Lots 312 & Pt.313.113.78 Lots 323, 325.326, 327, 330.331, Pt.452.56 332, 506, 509.64.83 13.20 14.35 25.00 113.78 452.56 Canton de Shipton \u2014 Township of Shipton Jacques, Raymond.Ptie 20-A-19, Rang 3.Caron, Lucien.Pt.n.s.19-F-2, Rang 3.Pt.n.s.20-B-l, Rang 3.Pt.n.s.20-A, Rang 3.S 54.48 S 54.48 253.36 253.36 St-François Xavier de Brompton \u2014 St-François Xavier de Brompton Boissé, Réjean.Ptie 5-C, rang 5.Paquet, Delourde.Ptie 12-B.Rang 2 .S 15.44 25.30 $ 15.44 25.30 Village de Greenlay \u2014 Village of Greenlay Gait Investment Corp.Ltd.Lot 10-A-81.Rang 1.* 137.69 $ 1,228.90 8 1,366.59 Campbell, Wm.Lots 9-A & B, Rang 1.77.87 908.31 986.18 Village de Melbourne \u2014 Village of Melbourne McKinnon, Mrs.Wm.Lot 105- * 24.28 % 24.28 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 197S, 10i' année, n\" S Ville de Danville \u2014 Town of Danville \t\tTaxes\tTaxes\t Propriétaire\tDésignation\tmunie.\tscol.\t Owner\tDescription\tMunie.\tSchool\tTotal \t\ttaxes\ttaxes\t Tisluck, Jean Paul\t\tS 245.60\tS 356.87\tS 602.47 \t.Pt.n.s.68, 11, 12, 13.\t____ 173.83\t199.49\t373.32 \t\t\t263.64\t263.54 \t\t\t\t Ville de Windsor \u2014 Town of Windsor Mercier, Robert.Lot No.297 et Pt.292.St-Pierre, Henri.Ptie 893 (Canton Windsor).S 394.10 S 394.10 137.43 137.43 Ville de Richmond \u2014 Town of Richmond Fowler, Donald.Lot 106-3.Storie, Mrs.W.A.Pt.389.Storie, Mrs.W.A.173.176, 366, 13, 14.Storie, Mrs.W.A.367.Storie, Mrs.W.A.176.Storie, Mrs.W.A.174.194.62 1,002.66 103.63 558.82 371.92 323.48 194.52 1,002.66 103.63 658.82 371.92 323.48 Donné à Richmond, Que., ce cinquième jour du mois de janvier, mil neuf cent soixante-douze.Le secrétaire-trésorier, 43913-2-2-0 Me Camille Dupuis.Municipalité du comté de Missisquoi Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Yves Fortin, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté de Missisquoi, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, au rabais, au bureau dudit conseil, eu la ville de Bedford, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi pour le paiement des taxes municipales, scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées; sur les divers lots ou morceaux de terrain ci-après désignés à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, avec les frais.Given at Richmond, Que., this fifth day of the month of January, nineteen hundred and seventy-two.Me Camille Dupuis, 43913-2-2-0 Secretary-Treasurer.Municipality of the county of Missisquoi Public notice is hereby given by the undersigned Yves Fortin, Secretary-Treasurer of the Municipal council of the county of Missisquoi, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock a.m., in the Office of said Council, in the town of Bedford, shall be sold by public auction the lots of land thereafter described for the payment of Municipal School and other taxes or charges due to the Municipalities hereinafter mentioned, unless same be paid with the costs before the sale.Municipalité de Notre-Dame de Stanbridge \u2014 Municipality of Notre-Dame de Stanbridge Noms des propriétaires\t\tNos officiels\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tInt.et frais\tTotal Names of owners\t\tOfficial Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Bale Lebel Co.\t.744.\t\t$ 3.13\t$ 1.85\t\t* 4.98 \t\t\t\t\t\t Municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge \u2014 Municipality of Saint Ignace de Stanbridge Forgue8, Léonide.2266.Fournier.Roger.____ 2303-2304-2306-2306 & 2307.S 2.60 160.60 * 2.60 160.GO QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 101 Municipalité de Saint-Ignace de Stanbridge (euite) \u2014 Municipality of Saint Ignace de Stanbridge (continued) \t\t\t\tInt.\t \t\tTaxes\tTaxes\tet\t Noma des propriétaires\tNos officiels\tmun.\tacol.\tfrais\tTotal Names of owners\tOfficial Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Tavan, Louis.P.2278, P.2279 & P.2280.Boisvert, Vital.2277-2273-P.2276-2689____ Daudelin, Ulysse.P.857-3054-3052.Morel.Léonard.2238-2239.S 215.20 S 234.51 (rép.d'ég.) 68.74 (rép.d'ég.) 62.95 (rép.d'ég.) 21.84 (rép.d'ég.) $ 449.71 68.74 62.95 21.84 Municipalité du canton de Stanbridge \u2014\t- Municipality of the township of Stanbridge\t Boomhower, Wayne.P.2907.\t.S 37.68\t$ 37.68 Municipalité du canton de Bedford -\t- Municipality of the township of Bedford\t Soûle, Doug.2167.\t.8 35.30\tS 35.30 Municipalité du village de Philipsburg -\t\u2014 Municipality of the village of Philipsburg\t Building Consultants Corp.P.40, P.41.2a, 2a-l, 2a-2, 2a-3, *4,262.27 $1,639.25 2a-4,2a-5, 2a-6, 2a-7, 2a-8, 2a-9, 76, 77, 78, 2.2-1, 2-2.P.84, P.106, P.107, P.115, P.5.Gendroska, Sylvester.P.49-38.35.50 Juratic, Filip.94.34 $5,901.52 35.56 94.34 Municipalité de la paroisse de Saint-Armand-Ouest \u2014 Municipality of the parish of Saint Armand-West Boucher, Eugène.P.253.- Davitt.William.206, 214, 218.Froidebise, Léon.91, P.385.Matthiesen.Karl.164, 169, 170, 171.174.Plouffe, François.P.44.Shaw, James.P.48-38-40-41, P.48-62-64, P.48N.S.Tittemore, Chester.1____ 239, 241, 246, 250, 252.Wilson, Roger.P.50, HS.24, 25.Gardner, Albert.P.132-11, P.131-22.Bordo, Royce.176,183.Border Lumber.P.48, P.48-54.Zimani, Joseph.P.101.Romahanyl, Gyozo.P.101.14.70 114.00 102.30 137.15 35.65 159.40 119.35 38.40 15.15 35.30 $ 44.60 191.15 347.14 101.04 473.65 410.00 60.50 116.95 18.76 40.25 118.20 $ 69.30 305.15 449.44 137.15 136.69 633.05 529.35 38.40 75.65 152.25 18.75 40.25 118.20 Municipalité de Venise-en-Québec \u2014 Municipality of Venise-en-Québec Burns, Claudette.P.191-198.Joncas.Normand.152-35.Choinière, Julien.P.153-34.Clairmont, Louise.191-32.Gagné, Armand.153:11-12.Gagné, Armand (Château Venise) .153-5.Helde, Tiidrick.132-38.$ 8.20 82.40 3.20 345.60 807.00 1,708.80 31.40 $ 48.92 1.90 205.20 477.37 1,014.60 10.40 .50 42.00 96.48 205.55 2.60 $ 8.20 141.72 5.60 592.80 1.380.95 2,928.95 34.00 102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 104' année, n° 2 Municipalité de Venis-en-Québec (suite) \u2014 Municipality of Venise-en-Québec (continued) Noms des propriétaires\tNos officiels\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tInt.et frais\tTotal Names of owners\tOfficiai Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Langlois.Daniel.\t191-133.\t.t 34.65\t8 33.57\t$ 5.50\tS 73.72 \t\t\t37.86\t\t111.71 Théberge, J.Bernard.\t\t\t102.87\t15.82\t217.09 \tMunicipalité de Rainville \u2014\tMunicipality of Rainville\t\t\t \t.2-8.\t.S 32.44\t* 396.92\t\tS 429.36 \t\t.3.64\t\t\t3.64 O'Cain, James.\t.P.141, P.158.\t.9.04\t\t\t9.04 Turcotte, Paul-André.\tP.237.\t.16.19\t188.65\t\t204.84 \t\t\t\t\t Municipalité de la paroisse de Frelighsburg \u2014 Municipality of the parish of Frelighsburg Giasson, Mme G.S.P.394.P.398, P.398A.P.400.S 291.96 P, 399 Marchessault.Yvan.278 .46.63 Pigeon, André.192.193,195,197.873.73 Pigeon, Roland.182, 185, 186, P.206, P.212 .504.80 Richards, Mrs.Charles.420 .8.74 Farnam, Bruce A.69.70, P.62.Gontovnick, Ben.290.P.292, 293.294, 296.S 16.37 708.35 191.98 $ 291.96 46.63 873.73 604.80 25.11 708.35 191.98 Municipalité du village de Clarenceville\u2014 Municipality of the village of Clarenceville Benway, Mrs.Florence.P.398.S 64.78 $ 61.94 $ 126.72 Municipalité de la paroisse de Saint-Georges de Clarenceville \u2014 Municipality of the parish of Saint George of Clarenceville Benway, Estate Charles.P.270.Demers, Noël et Cameron, Victor .343.St-Germain, P.E.59.Yurkewich, Mrs.0.533, 205-3-4.Zelinsky, J.Boomhower.William.P.201.Hachez, Roger.194.Lachance, André.P.212.6.27 20.94 4.14 13.81 45.49 33.77 57.80 76.12 187.78 88.52 20.08 66.33 4.14 33.77 57.80 76.12 187.78 88.52 Municipalité de la paroisse de Saint-Thomas \u2014 Municipality of the parish of Saint Thoma P.4-22.\tS 19.88\tS 34.82 P.37.\t51.00\t119.01 P.3-96.P.4-25-26, P.3-14-15,\t69.39\t93.48 P.4-142\t\t P.42-30.\t51.95\t148.48 P.42-69-71.\t67.90\t P.46.\t24.38\t5.51 21.\t3.00\t10.39 P.42.\t24.00\t30.72 P.46.\t\t18.67 54.70 170.01 162.87 200.43 67.90 29.89 13.39 64.72 18.67 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 103 Ville de Cowansville \u2014 Town of Cowanaville \t\t\t\tInt.\t \t\tTaxes\tTaxes\tet\t Nome des propriétaires\tNos officiels\tmun.\tscol.\tfrais\tTotal Names of owners\tOfficial Nos.\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and costs\t Brown, Warren D.Gogan, Est.Henry.Gratton, Mrs.Margaret Hi.'.'., Knight, Arthur J.Miller, Steven.Persons, E.J.Sayers, Edward.Thomas, Gerald.Vanderwerff, Hans.Pine Gables Nursing Home.Orbit Construction Corp.L.C.L.Enterprises Inc.Brome Land & Housing Develop.P.646-10, P.646-9.28, 29.P.107.P.436-159, P.436-160.124-303.P.52, P.14, P.8-1, 62-5, 62-6, 62-7, P.95, P.56, P.55.46.P.51, P.286 P.293.99-6, 96-28.P.17, 638-46-47.P.468.307-116-189-117-190-166-240.P.307 P.481.307-58-105-017-110-111-112-184-185-186-187; 307-114-188; 307-191;307-147; P.307-121-124; 307-165-164-163-241-242-246-243-245-130; P.307; 307-140; 468-167-307-132-135-137-138; 307-153-145-144, 143, 142, 141 $ 201.36\t8 201.36 77.57\t77.57 139.69\t139.69 38.40\t38.40 19.49\t19.49 647.95\t647.95 62.36\t62.36 440.70\t440.79 204.51\t204.51 87.52\t87.52 238.83\t238.83 6.25\t6.25 67.90\t67.90 Ville de Dunham \u2014 Town of Dunham Bates, Merrill.Brown, Walter.Comeau, James Edgar.Guoziunas, K.V.McEathron, Mrs.M.L.Starkey, Arthur L.Weidlich.Miss E.Collins, Joseph.Gilmore, Patrick.Hauver, Kent.Hesketh, W.Hooper, Fernand.Howland, Peter.McAndrew, Miss E.Walters, James.P.322.P.113.P.249, 257 747.748.P.692.P.381.P.842.P.552.P.554.P.566.P.555.P.555.P.555.P.550.P.555.$\t13.75\t$\t13.75 \t113.41\t\t113.41 \t256.87\t\t256.87 \t178.07\t\t178.07 \t40.05\t\t40.05 \t133.18\t\t133.18 \t35.13\t\t35.13 8\t7.19\t8\t7.19 \t7.02\t\t7.02 \t168.33\t\t168.33 \t37.22\t\t37.22 \t26.92\t\t26.92 \t90.08\t\t90.08 \t99.25\t\t99.25 \t99.29\t\t99.29 Donné à Bedford, ce cinquième jour de janvier mil neuf cent soixante-douze.Le secrétaire-trésorier, Yves Fortin, 43912-2-2-o Corporation du comté de Missisquoi.Given at Bedford, on this fifth day of January, nineteen hundred and seventy-two.Yves Fortin, Secretary-Treasurer, 43912-2-2-0 Corporation of the county of Missisquoi.Municipalité du comté de Frontenac Avis public est par les présentes donné par Luc-Lin Bourque, secrétaire-trésorier du Conseil Municipal du comté de Frontenac, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de ville, en la ville de Lac-Mégantic, lieu où le conseil du comté tient ses séances, JEUDI lé NEUVIEME jour de Municipality of the county of Frontenac Public notice is hereby given by Luc-Lin Bourque, Secretary-Treasurer of the municipal council of the county of Frontenac, that the hereinafter mentionned lands will be sold at public auction, in the Town Hall, in the town of Lake Mégantic, place where the county council holds its sittings, THURSDAY the NINTH day 104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes municipales, scolaires et autres charges dues aux municipalités ci-après mentionnées, sur les divers lots ou morceaux de terrain ci-après désignés, à moins qu'elles ne soient payées avant la vente, avec les frais.of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes and other charges due to the hereinafter municipalities upon the several lots or parcels of land hereinafter described unless the same be paid, with cost before the sale.Municipalité du canton de Lambton\u2014Municipality of the township of Lambton Propriétaires Owners\tNos des lots Nos.of lots\tNos des cad.Cad.Nos.\tRangs Ranges\tCantons Townships\tSuperficie ou mesures Area or measures\tTaxes munie.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tInt.et frais mun.Int.and Mun.costs\tTotal Bureau, Roland.\t32.\t\t8.\tLambton.Lambton.Lambton.\t1 Yi avec maison-with house 120.\t$ 60.00 92.50 301.88\t\t$ 3.00 4.50 11.95\tS 63.00 97.00 313.83 Gendron, Georges.\tPtie 6-B.Ptie 1-A.\t\t1-B.\t\t\t\t\t\t \t\t\tB.\t\tiyi.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité des Cantons Unis de Risborough et partie Marlow Municipality of \"Cantons Unis de Risborough ci partie Marlow\" Dallaire Michel.Dupuis.Florian Dupuis, Florian Dupuis, Florian Nadeau, Isidore 4-A.1-A, Ptie 1-B.12-B.13-A.6-B.7.\tRisborough.8.\tRisborough 8.\tRisborough 8.\tRisborough.8.\tRisborough.S 83.60\t$ 178.67\t$10.14 83.60\t84.60\t4.97 25.20\t28.20\t1.50 21.00\t23.50\t1.30 92.00\t94.00\t5.42 S 272.41 173.17 54.90 45.80 191.42 Municipalité de Marston-Canton \u2014 Municipality of Marston Township Poulin, Donald.Poulin, Donald.Poulin, Donald.Mueller, Mme-Mrs.Jane.Poser, Hcnry-August.Rouillard, Jacqueline.Mercier, Léo.Roy, Jacques.Pouliot, Camille.Doyon, Julien.Laurendeau, Roger.Lemieux, Lucien.O'Brien, Donald.Rhéaume, Louis-Denis.Mercier, Léo.116.\t\t3 118.\t\t3 120.\t\t3 142.\t\t3 125.\t\t3 162.\t\t4 182.\t\t4 232.\t\t5 249.\t\t5 327.\t\t7 326.\t\t5 31.\t\t2 Ptie 138.\t\t3 264.\t\t6 161.\t\t4 Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston.Marston., Marston.Marston.100 acres.100 acres.100 acres.300 x 225.35 acres .100 acres.100 acres.100 acres.100 x 100.100 acres.50 acres.S 45.34\t% 11.44\t$ 6\t54\t$ 63.32 45.34\t11.44\t4\t36\t61.14 45.34\t11.44\t\t\t56.79 42.50\t11.44\t3\t2(1\t57.14 85.00\t23.49\t8\t5(1\t116.99 59.55\t10.02\t7\tOS\t76.65 51.00\t26.99\t4\t25\t77.99 51.00\t11.44\t7\t65\t70.09 127.50\t71.09\t12\t66\t211.24 89.25\t\t8\t94\t98.19 157.25\t5.72\t17\t2.X\t180.25 66.15\t\t7\t40\t73.55 63.73\t22.20\t5\t94\t91.87 239.20\t46.89\t11\t'(7\t298.06 38.25\t20.32\t3\t20\t61.77 Municipalité de Notre-Dame-des-Boia \u2014 Municipality of Notre-Dame-des-Bois Moisan, Théodore Moisan, Théodore,___ Laflamme, Alcide.L'Heureux, Robert.St-James, Arthur.Ptie 23.\t\t6.Ptie 23.\t\t6.Ptie 34.\t\t5.Ptie 16.\t\t4.Ptie 18.\t\t9.Cheshara.Chesham.Chesham -Chesham.Chesham.17 x 27.500' x 800'.106' x 250*.50' x 100'.\\£ acre.$ 16.20\t\t 21.35\t$ 28.48\t 7.21\t17.80\t 10.00\t\t Municipalité de Saint-Robert Bellarmin \u2014 Municipalité of St-Robert Bellarmin 16.20 21.35 28.48 25.01 10.00 Saint-Robert Metal Corp.Saint-Robert Metal Corp.1-A.\t\t16.1-B.\t\t6.\t\t Risborough.Marlow.100.100.$ 14.84 179.67 $ 14.84 179.07 I QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10k, No.2 105 Municipalité de Saint-Samuel de LaoDroIet \u2014 Municipality of Saint-Samuel of Lake Drolet Propriétaires\tNos des lots\tNos des cad.\tRangs\tCantons\tSuperficie ou mesures\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tInt.et frais mun.\tTotal Owners\tNos.of lots\tCad.Nos.\tRanges\tTownships\tArea or measures\tMun.taxes\tSchool taxes\tInt.and Mun.costs\t Drouin, Léandre.\tPtie 128.\t\t2.\tGayhurst.\t\tS 15.85\t$ 20.63\t$ 4.09\t$ 40.57 La maison seulement est vendue, pas le terrain.The House only is sold, not the land.Municipalité de Val Racine \u2014 Municipality of Val Racine Bergeron, Gaston.\tPtie 395.\t\t9.\tMarston.\tH.\tS 47.20\t\t$ 47.20 \tPtie N.25\t\t1.\tChesham.\t50.\t16.70\t\t16.70 \t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Winslow-Sud \u2014 Municipality of Winslow-South Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri Lapierre, Henri 81.80.79.77.78.76.78.77.76.75.Ptie 80.79.Ptie S.O.78.77.76.75.5 S.O.5 S.O.5 S.O.5 S.O.5 S.O.5 S.O.4 S.O.4 S.O.4 S.O.4 S.O.3 S.O.3 S.O.3 S.O.3 S.O.3 S.O.2 S.O.Winslow.Winslow.Winslow.Winslow., Winslow., Winslow.Winslow., Winslow.Winslow., Winslow., Winslow., Winslow., Winslow., Winslow., Winslow., Winslow.S 15.12\t\t 23.31\t\t 11.02\t\t 20.79\t\t 17.96\t\t 18.90\t\t 15.75\t\t 12.60\t\t 6.30\t\t 9.45\t\t 14.17\t\t 12.60\t\t 8.82\t\t 177.98\t\t 9.45\t\t 10.71\t\t Municipalité de Saint-Augustin de Woburn \u2014 Municipality of St-Augustin of Woburn Lessard, Henri-Louis, Lessard, Henri-Louis.Lessard, Henri-Louis.Lessard, Henri-Louis.Lessard, Henri-Louis.Lessard, Henri-Louis.Ptie 3.Ptie 1, 2-A.6.10.11_____ Ptie 12, 2 1 7 7 7 7 Louise.\t83 acres____\tS 14.60\tS 10.69\t$ 1.01\t$ 26.30 Clinton.\t60 acres.\t3.16\t6.30\t.50\t9.96 Woburn.\t100 acres.\t33.84\t18.75\t3.07\t55.66 Woburn.\t81 acres.\t24.24\t10.35\t2.39\t36.98 Woburn.\t80 acres.\t13.44\t8.40\t1.13\t22.97 Woburn.\t100' x 100'.\t10.32\t6.45\t.94\t17.71 Municipalité de Frontenac \u2014 Municipality of Frontenac Vachon, Mme-Rrs.Réjeanne Paradis.\t44.\t\t1.\tDitchfield.\t61 acres .j$ 16.20\t\t\tS 16.20 \t\t\t\t\t\t\t\t Vraie copie.Donné à la ville de Lac-Mégantic, ce 5e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 43906-2-2-o Luc-Lin Bourque.True copy.Given at the town of Lake Mégantic, this 5th day of January, 1972.Luc-Lin Bourque, 43906-2-2-o Secretary-Treasurer. 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' Amie, n° 2 Municipalité du comté de Brome Municipality of the county of Brome Avis public est, par les présentes, donné par le soussi- Public notice is hereby given by the undersigned, gné, Joseph P.Lefebvre, secrétaire-trésorier du conseil Joseph P.Lefebvre, Secretary-Treasurer of the Munici- municipal du Comté de Brome que les terrains ci-après pal Council of the County of Brome, that the lands mentionnés seront vendus par encan public, au rabais, hereinafter described will he sold, by public auction, à quiconque offrira de payer les montants de deniers à in abating, to whomsoever will offer to pay the amount prélever, y compris les frais encourus, pour la moindre due on such lots including costs, for the least part of partie de chacun desdits terrains qui seront mis à l'en- any lot mentioned, the whole in default of previous chère, à défaut de paiement, avant la vente, des taxes payment of said amounts due, and the whole including municipales et scolaires et des frais encourus pour costs incurred, leading to this sale hereby advertised parvenir à ladite vente; au lieu où le conseil de comté for municipal and school taxes; at the County House, tient ses séances, à l'édifice du comté à Knowlton, in the Village of Knowlton, it being the place where JEUDI, le NEUVIÈME jour de mars prochain, 1972, the said Council holds its sessions, the sale to be held à DIX heures de l'avant-midi, à savoir: on THURSDAY the NINTH day of March next, 1972, at TEN in the forenoon, to wit: Municipalité de Bolton Ouest -\t- Municipality of West Bolton\t Noms des propriétaires\tNuméro du cadastre\t \t\tTaxes Names of proprietors\tCadastral number\t Budgen, Norman.p.401.S 108.25 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 95040.of the township of Bolton described under No.95040.Dionne, Paul E.386.17.25 Donald.Mme-Mrs.Michael K.p.385, 388, 389.66.70 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton, Of the official plan and book of reference of the township décrit sous Ie No 97370.of Bolton, described under No.97370.Jacques, Eugène.*.136.177.85 Commission Scolaire Protestante de Knowlton \u2014 Protestant School Municipality of Knowlton Joseph Charby.p.1354.g 74.60 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 96831.of the township of Brome described under No.96831.Mme-Mrs.John A.Cook.p.1186.219.09 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 100136.of the township of Brome described under No.100136.Mme-Mrs.Ralph S.Crandall.1067-4.1068-1, 1074-3.p.1264 .257.94 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome, Of the official plan and book of reference of the tnwnnhin sauf les Nos 97713 et 99211.of Brome, except Nos.97713 and 99211.townsmp Mme-Mrs.Robert Sissons.1253.>2g rr Mme-Mrs.Maria Lightbody.p.1218.~7Q.18 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 102957.of the township of Brome described under No.102957 Brandon I'\".Sykes.p.1228.246 71 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 89880.of the township of Brome described under No.89880.Brandon F.Sykes.1183.,no Qfi Donald McGovern.p.1176.\u2022.'.'.'.'.'.] 12106 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 103415.of the township of Brome described under No.103415 Bowes Holdings Corporation.1182.00 David McCarthy.26.Peter Bakolias.p.1192.'.'.'.] 737 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of referpn de Bolton.décrite sous le No 95066.of the township of Bolton described under No.9C00O.ce QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.10k, No.2 107 Commission Scolaire Protestante de Knowlton (tuile) \u2014 Protestant School Municipality of Knowlton (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Siegfried Buts.p.1194.8 10.91 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 92924.of the township of Bolton described under No.92924.Virginia Reid & Hans Ryter.1207, p.1208.125.21 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton, Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 102584.of Bolton described under No.102584.Frank Smit.p.521.91.93 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference He Bolton décrite sous le No 100221.of the township of Bolton described under No.100221.Mme-Mrs.Brian O'Reilly.p.1194.7.37 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 99646.of the township of Bolton described under No.99646.Mile-Miss Valerie Long.p.1193.36.72 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 101084.oi the township of Bolton described under No.101084.Warren R.Ohlhorst.326-22,326-23.475.61 Novab Ltée.102-22, p.103-35, p.103-36, p.103-37.10.60 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 103467.of Brome described under No.103467.Elsdon H.M.Succ-Est.1366-67.10.00 W.A.Matthew.p.1363.100.88 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 86172.of the township of Bolton described under No.86172.Patrick J.Prescott.p.507.17.04 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous Ie No 99208.of the township of Bolton described under No.99208.Richard Ferguson.405-19, p.405-20.72.42 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 101296.of Bolton described under No.101296.Mme-Mrs.John L.H.O'Brien.304 .30.17 Biagio W.Ricci.p.96.180.16 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 97779, sujet au bail.of the township of Bolton described under No.97779, subject to the lease.Mme-Mrs.Wolf Kutschke.113.66.09 Barry, Valentine.p.404 .34.40 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 95399.of the township of Bolton described under No.95399.Bolton Glen Development Company Limited.p.323, p.330, p.331, p.333.p.410, 411, 412, 414, 1,932.63 417, 418.419, 421.Salemark Associated Ltd.p.289.139.09 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 99057.of the township of Bolton described under No.99057.Norman Cowell.936-170,936-171,936-172.76.82 Gregor A.Lambourne.876.60.76 J.Gabriel Dulude.p.1325.65.79 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 102502.of the township of Brome described under No.102602.Mme-Mrs.Vivian Shufelt.205.206, p.207, p.208, p.209, p.210.76.82 Walter S.Stenhouse Jr.P-564.25.67 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 92264.of the township of Brome described under No.92264.Charles Simpson.P-936.9.96 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 94568.of the township of Brome described under No.94568. 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1973, 101' année, n° S Commission Scolaire Protestante de Knowlton (suite) \u2014 Protestant School Municipality of Knowlton (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Robert Rowe.p.936, 936-333, 936-335.$50.74 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 96544.of Brome described under No.96544.Butterfield Barbecues Ltd.p.96.71.20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 99583.of the township of Brome described under No.99583.Jay Technical Inc.p.215.426 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 102460.of the township of Brome described under No.102460.South Sounds Limited.p.432.p.433.9-93 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome Of the official plan and book of reference of the township décrite sous le No 98616.of Brome described under No.98616.Commission Scolaire Protestante de Cowansville ¦\u2014 Cowansville Protestant School Board James Douglas.p.7.$ 4.91 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Farnham Est décrite sous le No 84636.of the township of East Farnham described under No.84636.Llewellyn Page.p.20.211.74 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Farnham Est décrite sous le No 92601.of the township of East Farnham described under No.92601.Pierre Veillon.p.7, p.1, 6, p.8.273.89 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Farnham Of the official plan and book of reference of the township Est décrit sous le No 101323.of East Farnham described under No.101323.Arnold Weinhold.p.21.25.18 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Farnham Est décrite sous le No 96281.of the township of East Farnham described under No.96281.Walter Piercy.227-23.143.25 Municipalité du Canton de Potton \u2014 Municipality of the Township of Potton Alexander, Mme-Mrs.Donald E.p.834.$ 40.19 Jersey Sidney.p.565, 83-B.134.00 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 96410.of Potton described under No.96410.Labranche, J.Charles.943, p.689 .201.19 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 97537.of Potton described under No.97537.Labranche, J.Charles.586.587, p.689.253.19 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 92607.of Potton described under No.92607.Lague, Denis.p.274.106.19 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Potton décrite sous le No 100812.of the township of Potton described under No.100812 Loisos, Nicholas.p.032.g 35 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Potton décrite sous le No 102769.of the township of Potton described under No.102769.Petroni, Dominique.1107.139 74 Poirier, Aimé.p.703.17 67 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Potton décrite sous le No 99966.of the township of Potton described under No.99966. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.10k, No.2 109 Municipalité du Canton de Potton (euité) \u2014 Municipality of the Township of Potton (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Pouliot, Roméo.603.$124.08 Pouliot.Rosaire.p.172, p.178, p.271, p.274.,.99.68 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 66779.of Potton described under No.66779.Quarry, Patrick.1030, 1031, p.961.19.66 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 102024.of Potton described under No.102024.Scott, Mme-Mrs.Michael B.963, p.1032.80.07 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 100175, sauf partie de 963 décrite sous le of Potton described under No.100176, except part of 963 No 101149.described under No.101149.Scoreb Incorporated.p.963.;.97.64 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Potton décrite sous le No 101149.of the township of Potton described under No.101149.Shaggy Dog Hotel Inc.p.835, p.840.673.05 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton, Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 102580.of Potton, described under No.102580.Tougas, Andre.572,573.170.07 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Potton, Of the official plan and book of reference of the township sauf parties vendues par No 67465.of Potton, except parts sold by No.67465.Zwicker, Charles E.p.1103.85.90 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Potton décrite sous le No 98428.of the township Potton described under No.98428.Commission Scolaire Catholique d'Eastman \u2014 Catholic School Commission of Eastman Dodier, Gérard.1312, 1313, 1314, 1322.$ 206.31 Fontaine, Renald.1479-154 .30.02 Labelle, Yvan, Succ.-Est.p.1468 .22.62 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 100651.of the township of Bolton described under No.100551.Lévesque, Jean M.Mme-Mrs.p.1468.44.63 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 104691.of the township of Bolton described under No.104691.Beaudin, Rouville.p.1477-75.43.67 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 95172.of the township of Bolton described under No.95172.St-Louis, Raymond.p.1468.57.02 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 96464.of the township of Bolton described under No.96464.Séguin, Denis Mme-Mrs.p.1477-53.22.62 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 99357.of the township of Bolton described under No.99367.Dubois, Claude.p.1477-33.30.02 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 102192.of the township of Bolton described under No.102192.Lac Webster Development Inc.p.1478-9.p.1478-112, 1477-39, p.1477, p.1478.202.06 Grégoire Toussaint.p.983.11.30 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 96886.of the township of Bolton described under No 96886.Broome, John M.p.1276.27.96 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 96525.of the township of Bolton described under No.96526. 110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 104' année, n\" 2 Commission Scolaire Catholique d'Eastman (suite) \u2014 Catholic School Commission of Eastman (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre _ Taxes Names of proprietors Cadastral number Heathfield, Mme-Mrs.Rose.p.1168.J 6.66 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 104521.of the township of Bolton described under No.104521.Gaffet.Lucien.p.1377.39.73 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 103047.of the township of Bolton described under No.103047.Wheeler.Byrhl F.p.1164.p.1168 .74.05 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton, Of the official plan and book of reference of the township sauf parties vendues par No 102375.of Bolton, except parts sold by No.102375.Commission Scolaire du Comté de Stanstead \u2014 Stanstead County School Board Baillie.Thomas R.p.1622.* 225.98 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 99313.of the township of Bolton described under No.99313.Baker.Grant.1482-23.107.17 Fairhead.Harold Mme-Mra.p.1884, p.1885.p.1886.p.1887, p.1888 .449.92 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous les Nos 90256 et 96121.of Bolton described under Nos.90266 and 96121.Fee, Elston.p.1881.p.1882, p.1884, p.1885, p.1886.126.67 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous les Nos 90202 et 90203, sauf le No 98283.of Bolton described under Nos.90202 and 90203, less No.98283.Gent, Adelaide M.Mme-Mrs.1461-23.79.72 Graham, Brian C.L.p.1648.174.67 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 96686., of the township of Bolton described under No.96586.Markham.Robert A.Mme-Mrs.p.1881.p.1884, p.1885, p.1886.568.35 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous les Nos 90584 et 98283.of Bolton described under Nos.90584 and 98283.Mann, G.A.Harley Mme-Mrs.1483-44 .76.96 Davidson, Willie Mme-Mrs.p.1641.36.94 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 103943.of the township of Bolton described under No.103943.Phaneuf, Stanley.p.1401, p.1400, 1407, p.1413.p.1413-C, p.1413-D 114.47 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 103722.of Bolton described under No.103722.Pathy.Lawrence G.1498.1683 .87 38 Page, Herman.p.1477-36.87! 76 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of Said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 96598.of the township of Bolton described under No.96598.Ruck, Stanley.p.1*13.p.1413-A, p.1413-B.p.1413-C, p.1413-D, 76.96 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the townshiu décrit sous le No 96186.of Bolton described under No.96186.Smith, E.Gerald M.& Mmc-Mr.-Mrs.1624, 1625.807.73 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the townshin décrit sous le No 88644.of Bolton described under No.88644.Smith, W.E.p.1479-191.23.68 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 99578.- of the township of Bolton described under No.99578.Thomson, Kenneth Mme-Mrs.p.1456, p.1459.400 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the townshin décrit sous les Nos 87720, 90229 et 98706.of Bolton described under Nos.87720, 90229 and 98706. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IS, 197S, Vol.m.No.S 111 Commission Scolaire du Comté de Stanstead (suite) \u2014 Stanstead County School Board (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Thomson, Kenneth B.1398, 1600, 1601.1499, 1502, p.1603, p.1604, S 311.87 p.1605, 1580, 1582.Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 90922.of Bolton described under No.90922.Wolf, Andrew.p.1477-32, p.1477-50.134.69 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous les Nos 95699 et 94878.of Bolton described under Nos.96699 and 94878.Townsend, Gordon.1483-37 .76.01 Westover, Gerald.1403, p.1418.162.17 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 83454.of Bolton described under No.83454.Municipalité Scolaire St-François-Xavier de Shefford \u2014 School Municipality St-François Xavier de Shefford Jacques Cooke.127-102.S 8.98 Municipalité de Bolton Est \u2014 Municipality of East Bolton Davidson, James.967.S 50.22 Galvin, Peter.p.1196, p.1197, p.1304, p.1305, 1306.90.70 Rozenski, Janusz.p.1172, p.1174, p.1175, 1299, 1302.94.88 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous les Nos 90791 et 92224.of Bolton described under Nos.90791 and 92224.Schulz, Klaus.p.1193.4.90 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 95613.of the township of Bolton described under No.95613.Galvin, Joseph A.947,949.21.89 Galvin, Joseph A.p.951, p.953.14.63 Galvin, Joseph A.p.958, 974.13.31 Galvin, Joseph A.p.1181, 1289, 1301.41.25 Galvin, Joseph A.p.1169.8.20 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Bolton décrite sous le No 85155.of the township of Bolton described under No.85155.Commission Scolaire de St-Edouard de Knowlton \u2014 School Commission of St-Edouard de Knowlton Boisclair.Pierre.p.1275.$ 70.26 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Brome décrite sous le No 100814.of the township of Brome described under No.100814.Choinière.Roger.936-63,936-64,936-65.88.91 Gagnon, Jean Claude.p.1089, p.1090-1.95.20 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Brome Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 98652.' of Brome described under No.98652.Pelletier, Rosario.936-299, 936-300.45.49 Commission Scolaire Protestante de Sutton \u2014 Protestant School Commission of Sutton Mme-Mrs.John Alper & Mme-Mrs.Stanislaw Greniuk 488, 489 Brome, p.1402, p.1403 Sutton.S 98.26 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 86362.of Sutton described under No.86362.Ross Burnett.1170, 1343, p.1344, p.1345.708.05 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 105508.of Sutton described under No.105508. 112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 10k' année, n° 2 Commission Scolaire Protestante de Sutton (suite) \u2014 Protestant School Commission of Sutton (continued) Noms des propriétaires Numéro du cadastre Taxes Names of proprietors Cadastral number Camp Clayton Mme-Mrs._.p.468.t 33.79 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 102762.of the township of Sutton described under No.102762.Centennial Celebration Children's Village.p.1367, p.1368 .23.59 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 93726.of Sutton described under No.93726.George Derby.p.1269 .73.09 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 89675.of the township of Sutton described under No.89675.Felix Mirbt Mme-Mrs.p.1147 .245.80 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 85495.of the township of Sutton described under No.85495.Gerald Morgan M.& Mine-Mr.& Mrs.p.550, 551.68.45 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Sutton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 92178.of Sutton described under No.92178.Mme-Mrs.Nora Patterson.p.408 .12.67 Parties dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Parts of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrites sous le No 100597.of the township of Sutton described under No.100597.Jacob S.Rangosch.p.542.17.38 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 92378.of the township of Sutton described under No.92378.Mme-Mrs.Edith Wetherby.27.28.80 Mme-Mrs.Clarence Wilson.p.1269.22.15 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 104031.of the township of Sutton described under No.104031.Roland C.Wilson.p.1269.87.29 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 92447.of the township of Sutton described under No.92447.Norman Wright._ p.545.51.12 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 100859.of the township of Sutton described under No.100859.Homer M.Jaquays Jr.p.631.42.67 Partie dudit lot dee plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous le No 92618.of the township of Sutton described under No.92618.Quintin Automobile Inc.p.838.6.56 Partie dudit lot des plan et livre de renvoi officiels du canton Part of said lot of the official plan and book of reference de Sutton décrite sous les No 100858.of the township of Sutton described under No.100858.Municipalité de St-Etienne de Bolton \u2014 Municipality of St-Etienne de Bolton Brome Estates Inc.509, 510, p.611, p.612, p.513.j 143.94 Des plan et livre de renvoi officiels du canton de Bolton Of the official plan and book of reference of the township décrit sous le No 89971.of Bolton described under No.89971.Joseph A.Galvin.950, 952.35.25 Donné à Knowlton, P.Q., ce 5e jour de janvier, 1972.Given at Knowlton, P.Q., this 5th day of January 1972.'* Le secrétaire-trésorier, J.P.Lepebvte 43907-2-2-O J.P.LEFEBVRE.43907-2-2-O Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 197S, Vol.101, No.S 113 Municipalité du comté de Bonaventure Avis public est par les présentes donné par Douglas Smollett, secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Bonaventure que les propriétés immobilières décrites ci-dessous seront vendues à l'enchère publique, au Centre Culturel, New Carlisle, JEUDI le NEUVIÈME jour du mois de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour le montant des taxes municipales et scolaires dû sur icelles, avec ensemble les frais, à moins que lesdites taxes et frais ne soient payés avant la vente, à savoir: Municipality of the county of Bonaventure Public notice is hereby given by Douglas Smollett, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Bonaventure that the immovables property hereinafter described will be sold at public auction on THURSDAY the NINTH day of the month, of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon/for amount of municipal and school taxes due thereon, together with costs, unless the said taxes and costs are paid before the date of the sale, to wit: Municipalité de Saint-François d'Assise \u2014 Municipality of Saint-François d'Assise Nom du propriétaire Name of proprietor No du cadastre et superficie Rang Canton No.of cadastre and area Range Township Taxes munio.Munie, taxes Taxes eoolaires School taxes Mme WiUie Arsenault.43, 116.68 A.1 Riv.Mat.Matapédia.8 15.37 $ 23.20 Municipalité de Saint-Alexis de Matapédia \u2014 Municipality of Saint-Alexis de Matapédia Adrien Levesque.Pt.6A &.Bât., 6750 Pds Adrien Levesque.Pt.7A & Bât., 8475 Pds.Adrien Levesque.14A & 14B, 128 Ac.Lucien Casista.Pt.21 & Bât., 150 ac- 1 Riv.Rest.1 Riv.Rest____ 1 Riv.Rest____ 1 Riv.Mat____ Matapédia____ Matapédia.Matapédia.Matapédia- 19.37 21.06 8.38 10.47 64.07 69.66 35.66 58.77 Municipalité de Pointe à La Croix \u2014 Municipality of Pointe à La Croix Alfred Beaulieu.Mrs.Fred Boudreau.Paul Emile Bonniel.Suce.Fred Boudreau.Rhéal Tardif, Jean Ruel.occup.Suce.Isidore Day.Suce.Isidore Day.Real Frigon.Yvon Grégoire.Alex Levesque.Paul Perron.A97 & Bât.16, 155 PC.22, 45.560 PC.34 & Bât.23, 79A.Pt.38 & Bât., 15.5A.Pt.1A, 65.3A.2 B.15.6A.Pt.37 & Bât.11,000 PC.36, 109A.Pt.3, Pt.4.59A.41 & Bât.99A.Restigouche.Mann.B.Mann.B.Mann.B.Mann.6.Mann.Oak Point.Mann.Oak Point.Mann.A.Mann.4.Mann.Oak Point 2 .Mann.B.Mann 226.41\t81,479.26 6.95\t17.09 20.10\t56.37 5.62\t95.20 18.06\t51.02 24.95\t151.79 9.00\t56.88 10.34\t122.90 6.30\t21.83 10.48\t67.66 13.71\t164.38 Municipalité d'Escuminac \u2014 Municipality of Escuminac Daniel Brown.Clifford Gaudin.Fred St-Onge.Robert Williamson.William Court.William Court.James Gaudin.233, 94 ac____ House only.Pt.7 & Bldg.Pt.6 & Bldg Pt.209, 64 ac 33.29 ac.Pt.7, 82 ac.Seig.Shoolbred.Nouvelle.Esc.East.Nouvelle Escuminac W.Nouvelle.Pointe à la Garde.Nouvelle.South Shoolbred.Nouvelle.Shoolbred.Nouvelle.Escuminac East Nouvelle.64.82 15.10 23.82 13.82 20.42 11.50 12.12 165.04 25.73 18.74 13.73 50.07 25.03 67.90 Municipalité de Nouvelle \u2014 Municipality of Nouvelle Charles Nadeau Suce 17B & Bât., 51,600 P.C Ouest Pt.Sud Ouest Nouvelle 8 14.70 114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Municipalité de Carleton Sur Mer \u2014 Municipality of Carleton Sur Mer Nom du propriétaire Name of proprietor No du cadastre et superficie Rang Canton No.of cadastre and area Range Township Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Suce.Anna Cuite Bernard.60A1 (Banc).1.Carleton.S 30.37 i 217.00 H.B.Savage.33 G.2.Carleton.34.61 659.76 Albert Leblanc.44.2.Carleton.1.20 Municipalité de Maria \u2014 Municipality of Maria Mme Rita Harquail Ferlate.Est Pt.25-26-1.25 ac.1.Maria.S 6.75 » 42.00 Mme Rita Harquail Ferlate.15a, 25 ac.2.Maria.6.75 42.01 Municipalité de Grande Cascapédia \u2014 Municipality of Grande Cascapédia Lome WUlet Estate.295.1.New Rich____ S 34.76 S 138.29 Municipalité de la Commission Scolaire Catholique de New Richmond Municipality of the Catholic School Commission of New Richmond Mme Alexis Arsenault.79-22.1.Abel Bouffard.P.45 & Bât.1., Oscar Brousseau.P.384 & Bât.P.Cascapédia Elide Cormier.P.436.2.Elide Cormier.P.628 & Bât.3.AdelbertCyr.123-18.1.AdelbertCyr.123-17.1.Elphège Gendron.155 NS & Bât.1.Delphis Leblanc.P.196.1.Wilfrid P.Leblanc.Pt.72-9, roulette.1.Marius Levesque.153 NS & Bât.1.Marius Levesque.156 NS & Bât.1.Marius Levesque.Pt.612.4.Léonda Mercier.112-20 & roulette.1.Alexis Normandeau.Pt.33.1.Y von Normandeau.Pt.200.1.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich New Rich New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.New Rich.6.83 .38 17.86 5.35 5.35 34.32 4.77 16.76 33.10 36.51 3.42 163.63 4.19 123.66 84.73 730.80 100.64 3.17 145.74 26.22 26.22 269.40 32.09 102.30 380.10 418.14 38.04 131.37 45.97 708.00 Municipalité de la Commission Scolaire de Saint-Edgar Municipality of the School Commission of Saint-Edgar Elide A.Cormier.Pt.796.7.New Rich.Jean-Marie Gagné.Pt.801 & Bât.New Rich .Norbert Gagné.Pt.795.New Rich.Eddy R.Leblanc.Pt.776.6.New Rich.Gérard Landry.Pt.28 sud & Bât.Robidoux.Julien Cormier.9 sud.Robidoux.Julien Cormier.10 sud.Robidoux.Julien Cormier.Pt.8 & Bât.Robidoux.Edmond Lapointe.7 Nord & Bât.Robidoux.18.24 20.86 3.31 16.66 52.15 193.23 50.48 41.89 108.87 17.11 17.11 147.96 182,88 Municipalité de Saint-Alphonse \u2014 Municipality of Saint-Alphonse Donald Arsenault.Pt.1140 & Bât.100 ac.7.Hamilton.Mme Léona Bernard, Suce.Ben Bélanger, Léandre Bernard occ.Pt.1130, 18J^ ac.7.Hamilton.S 47 83 Eymard Bourdages.Pt.1022, 60 ac.5.Hamilton.6.76 Succ.Joseph Dugas, Joseph Dugas Sr., occu.Pt.1079.1/8 ac.S.Hamilton.a.06 66.87 7.27 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 1972, Vol.10i, No.2 115 Municipalité de Saint-Alphonse (ëuite) \u2014 Municipality of Saint-Alphonse (continued) Taxes Taxes Nom du propriétaire No du cadastre et superficie Hang Canton munie.scolaires Name of proprietor No.of cadastre and area Range Township Munie.School taxes taxes Succ.Paul W.Cyr, Jos C.Laviolette, occ.Pt.1185 & Bât.98 ac.exemption 50 pieds large autour du lac en faveur Albert Dugas.Raoul St-Onge.exempt Roméo Bernard (100' x 125').Pt.1181 & Bât.74 ac.Frédéric Miousse.Pt.1179 & Bât.45 ac.Hamilton.Hamilton.Hamilton.$ 23.09 82.35 92.94 S 56.07 423.65 Municipalité de Caplan \u2014 Municipality of Caplan Gabriel Babin.Gabriel Babin.Gabriel Babin.Gérald Bourdages.Jacques Bourdages, Polycarpe Gauthier, occ.Jacques Bourdages, Polycarpe Gauthier, occ.Jacques Bourdages, Polycarpe Gauthier, occ.Alonzo Cyr.Alonzo Cyr.Félix Bernard.René Ferlatte, occ.Bernard Arsenault, occ, Emile Lepage.Eva McLellan suce, Preston McLellan, occ.Eva McLellan, succ.Preston McLellan, occ.Nicol Querry, Succ.Neil Campbell.Elias R.Campbell, occ.Succ.Neil Campbell, Clifton Campbell, occ.Succ.Samuel Ferlatte, Gervais Ferlatte, occ.Succ.James B.McLellan, Viola McLellan, occ.(moins Pt.sud (180 x 150) Pt.1 & Bât.47 ac.1.486.60 ac.3.653.100 ac.4.Pt.50 & Bât.145 x 120.1.Pt.18 & Bât., 25 ac.1.Pt.15.19 ac.1.Pt.1001, 20 ac.5.Pt.48 & Bât., 125 x 65.1.Pt.791, lOac.3.Pt.917.30 ac.4.Pt.807, 25 ac.3.Pt.43 & Bât., 44 ac.1.Pt.603, 20 ac.2.Pt.13 & Bât., 40 x 50.1.Pt.471 & Bât., 18 ac.2.Pt.471 & Bât., 18 ac.2.928, 48 ac.4.42&Bât.50ac.1.Hamilton.New Rich.New Rich.Hamilton.\t8 192.44 18.36 21.00 92.20 \t43.05 Hamilton-\t2.20 \t1.40 100.45 2.10 \t2.10 \t2.17 \t61.45 \t2.03 New Rich\t66.94 10.79 New Rich\t28.61 \t3.36 \t61.60 758.37 118.75 Municipalité de la Commission Scolaire de Val d'Accueil \u2014 Municipality of the School Commission of Val d'Accueil Beauchemin, Fernand.Pt.1812.13.Cox.t 222.04 Boissonnault, David.Pt.22>$.1.Garin.23.01 Boissonnault.Edgar.36.2.Gann.90.65 Bujold, Mme Isidore.Pt.1203 E.8.Hamdton.101.99 Cousin, Edmond.Pt.1232.9.Hamilton.'gf-Zg Cousin, Hector.1192.8.Hamdton.,2H2 Delarosbil.André.Pt.1704.10.Cox.- 137.60 Ferlatte, Louis.Pt.1779.12.Cox.162.87 Gauthier.Alphée.Pt.1678.10.Cox.108.79 Lebrasseur.Edmond.Pt.1508 .6.Cox.Loisel Eugène.Pt.1706.10.Cox.137.64 Maldenav Georges.Pt.1703.10.Cox.134.92 Buiold René.208 & Bât.1.Hamilton.% 42.97 158.68 704 .5.Hamilton Poirier, Albert, occ.838 & Bât.3.Hamilton.35.99 199.00 Poirier Eudore.209 & Bât.1.Hamdton.38.48 281.93 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Municipalité de Bonaventure \u2014 Municipality of Bonaventure Taxes Taxes Nom du propriétaire No du cadastre et superficie Rang Canton munie.scolaires Name of proprietor No.of cadastre and area Range Township Munie.School taxes taxes Jean Paul Poirier.345-2, 345-4.53.68 ac.1.Omer Bujold.383-9 & Bat, 4800 pds.1.Leopold Nadeau.407-3 & Bât, .35 ac.1.Jacques Arbour.Pt.862 & Bât, 44 ac.3.Chariot Pelletier.Pt.32 25x60.Normand Pelletier.Pt.32 176 x 250.Johnny Woods.951 & Bât, 12 ac.La Cie de Bois de Bonaventure 50% de chacun de ces lots et Inc.bâtisses: 416-1, 418-2, P.422, P.423-3, P.424-1, 424-2, P.426-2,426-3, P.426-2.426-3.P.427-2, P.427-3, P.428-5, P.428-2, P.432-7.P.396, P.P.417-1, 417-A-l.417-6.416-A-4, 417-3, 418-A-l, 419-1, 419-2, 420-3.420-1, 420-2, 422-A, 423-A, 409.1.Hamilton.S Hamilton.Hamilton.Hamilton.Cox.Cox.Cox.39.51 $ 66.19 133.41 107.68 89.87 3.16 31.41 393.69 160.81 116.35 6.92 88.68 6.69 Hamilton.1,140.99 3,414.93 Municipalité de St-Elzéar \u2014 Municipality of St-Elzéar Marie L.Bourdages.Bât sur Pt.1774.12.Cox.S 29.08 Wenceslas Poirier.1848 & Bât, 96 ac.14.Cox.81.24 Gérard Hudon.1844 & Bât.96 ac.14.Cox.89.36 $ 216.60 Gérard Hudon.49.44 ac.2.Garin.44.68 108.30 Victor Glazer.1860 & Bât, 96 ac.14.Cox.65.88 Municipalité du comté de Bonaventure \u2014 Municipality of the county of Bonaventure Leon L'Italien, Alonzo Celeste Occ.1.4.Carleton.$ 27.00 S 96.22 Municipalité de New Carlisle \u2014 Municipality of New Carlisle FordBeebe.2385,7.66.FordBeebe.2285, .17.Ford Beebe.2284, .25.Ford Beebe.2317 & Bldg, 7.90.Ford Beebe.2386, 7.66.Andrew Buttle.2358 & Bldg, .50.Ralph Francoeur.2043 & Bldg, .58.Ralph Francoeur.2044 & Bldg, .15.David Parise.1329, 15.07.David Parise.1321, 7.00.Archie Dobson.1384, 20.13.Johnson Sawyer.1347,19.63.Johnson Sawyer.1348,19.59.T.S.Caldwell.727.25.68.T.8.Caldwell.728, 25.68.T.S.Caldwell.729,51.42.T.S.Caldwell.941,17.39.Johnny G.Buttle.917, 10.89.Johnny G.Buttle.918,3.11.Hector Poirier.1464, 32.13.Hector Poirier.1465,31.97.Hector Poirier.1466.32.13.Manford Dobson.1971, .72.Henri Pitre.760.16.37.John A.Thompson.924,9.38.John A.Thompson.2368,2.00.Cox.1 Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.5.20 S\t10.40 .19\t.28 .20\t.50 111.93\t226.17 5.20\t10.40 42.88\t 173.54\t154.32 173.53\t154.32 1.63\t22.40 .81\t11.20 .40\t .39\t .39\t 1.28\t 1.28\t 2.57\t .87\t .33\t .09\t .64\t.77 .64\t.77 .64\t.77 2.88\t .33\t .28\t .80\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10i, No.2 117 Municipalité de New-Carlisle (suite) \u2014 Municipality of New-Carlisle (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor No du cadastre et superficie Rang Canton No.of cadastre and area Range Township Taxes munie.Munie, taxes Taxe3 scolaires School taxes John A.Thompson.2307, .25.Mrs Albert Billingsley.2045 & Bldg.62.Stuart Assels.2364, 5.33.Henry Smollett (Harry).Pt.1327, 27.13____ John August Holmes.1051, 20.70.E.E.Law (Estate).Pt.1327.27.13.Chaleur Bay Autobus.2147 & Bldg, 1.09.Claude Benoit.1136, 2.76.Adam Dobson Estate.2275,2.00.Dobson Buttle.1385, 31.13.Dobson Buttle.1380,31.13.Alvin Astles Estate.2286, 1.90.Mrs.A.Ross Estate.1896-12, .15.John L.Smith Estate.91A.07.William Morrison Estate.1340,53.78.Charles Garrett Estate.70, 1.90.William Chouinard Estate.1896-14, .29.James Flowers Estate.1500, 16 ac.Edmund Dobson Estate.2363, 2.50.Edmond Tozer Estate.1468, 48.88.Bertha Babin.1352,4.97.Andrew R.Caldwell Estate.2162, .08.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Coc.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.Cox.$ .10 42.81 2.13 .55 1.04 .55 10.90 .14 .SO .62 .02 .76 .15 .07 1.08 .76 .29 .32 1.00 .98 .10 .64 t 70.94 158.96 233.31 Municipalité scolaire protestante de Baie des Chaleurs \u2014 Protestant School Municipality of Chaleur Bay Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Ronald B.Gilker.Cyril Gallon.Glenburn Astles.Glenburn Astles.Vestie Buttle.Estate,William B.Chatterton.George Thompson.Ronnie Gallon.David Doherty.David Flowers.Alfred Main.William Smith.William Smith____.William Smith.Mrs Ronald Huntington, Clair Hottot Occ.Clarence Walker.Randolph McRae Estate Jessie McLellan Occ.J.D.Ross, Lyall Ross Occup.Edison Ross Occ.John E.Ross Pt.920.Pt.912.Pt.1129.Pt.1128.Pt.1916 B.1919.1983 & Bldg.Pt.1896-21.2024 & Bldg.2056.2057.2403.2404.2405.2406.2420.2421.2422.Pt.651.Pt.2044 & Bldg.Pt.81.Pt.1896-8 & Bldg.2332 & Bldg.2310 & Bldg.5.50 ac.1371, 28.67 ao.Pt.100 &Bldg, 12.42 ac.Pt.2082 & Bldg, 104' x 227.7'.Pt.1896-18 ABldg 35'x,50'.Pt.1896-8 & Bldg, 20 ac.Pt.1896-9 & Bldg, .07 ac.Pt.1026.Pt.816 & Bldg, 24 ac.Bldg on 675.97 & Bldg.454,331/3 ac.78, 20 ae.\tCox.\t9 0.10 J\t20.57 \tCox.\t.83\t20.57 \tCox.\t.19\t20.57 \t\t1.59\t20.67 \tCox.\t.83\t20.57 \tCox.\t2.80\t20.57 \tCox.\t2.25\t20.57 \tCox.\t.07\t20.57 \tCox.\t117.90\t20.57 \tCox.\t2.95\t20.57 \tCox.\t1.45\t20.57 \tCox.\t.39\t20.57 \tCox.\t.38\t20.57 \tCox.\t.38\t20.57 \tCox.\t.38\t20.67 \tCox.\t.39\t20.57 \tCox.\t.39\t20.57 \tCox.\t.39\t20.57 \tCox.\t\t57.40 \tCox.\t69.09\t246.00 \tCox.\t.20\t1.32 \tCox.\t63.97\t123.91 \tCox.\t38.36\t85.39 \tCox.\t49.62\t83.05 \tCox.\t1.32\t12.53 \tCox.\t133.09\t421.15 \tCox.\t217.40\t289.81 \tCox.\t50.27\t88.70 \tCox.\t66.78\t139.80 \tCox.\t.07\t1.30 \tCox.\t1.66\t5.20 6.\t\t40.34\t72.14 4.\t.Port Daniel.\t26.00\t20.45 1.\t\t8.80\t89.76 2.\t\t47.28 10.63\t176.66 68.06 \tHope.\t\t 118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n\" 2 Municipalité de la commission scolaire de Mgr Matte \u2014 Municipality of the School Commissioner of Mgr.Matte Taxes Taxes Nom du propriétaire No du cadastre et superficie Rang Canton munie.scolaires Name of proprietor No.of cadastre and area Range Township Munie.School taxes taxes Jacques Aspirot.1513.M me Ernest Castilloux.1405.Mme Alcide Fulham.1230 & Bât.Rosario Fulham.1398 Aimé Joseph.546 & Bât.Hotel Royal Co.Enrg.2007-2 & Bât.Hotel Royal Co.Enrg.2007-3 & Bât.Cyprien Benwell.Bât sur 662.Valmont Briand.141 & Bât.Mme Emely (Fred) Imhoff____ 1019.,.Henri Lapierre.800 & Bat.Oscar Bourdages.270.Edouard Mclnnis.286 & Bât.Edouard Mclnnis.295 & Bât.Jean Paul Anglehart.849 & Bât.Jean Paul Anglehart.1284 & Bât.Jean Louis Duguay.864 & Bât.Hypolyte Fulham.1407.«.Rosario Fulham.1421 & Bât.Rosario Fulham.1096 & Bât.MagellaHorth.1075.MagellaHorth.1444.Succ.Alexis Leblanc.906 & Bât.\u2022.David Parise.1063 & Bât.David Parise.1064 & Bât.Arthur Ross.654.Albert Francoeur.691.Emile Bélanger.798.Joseph Biais.801.Gabriel Biais.1018 & Bât.9.Louis (Père) Foureaudot.516.Cox.\tS 22\t.96\t$ 66.\t85 Cox.\t8\tIS\t21.\t26 Cox.\t6\t99\t24.\t69 Cox.\t25\t.76\t87.\t28 Cox.\t136\t.23\t307.\t53 \t\t\tProt.\t \t\t\t102.\t74 \t\t\tCath\t Cox.\t23\t70\t54.\t10 \t\t\tProt.\t \t\t\t102.\t75 \t\t\tCath\t Cox.\t23\t.70\t54\t00 Port Daniel.\t22\t.77\t18,\t28 Port Daniel.\t\t\t306.\tor, Cox.\t\t\t38,\t46 Port Daniel.\t66\t.63\t179.\t10 Port Daniel.\t\t.80\t38,\t49 Port Daniel.\t26\t.60\t186.\t88 Port Daniel.\t25\t.60\t186.\t29 Cox.\t\t\t98.\t70 Cox.\t\t\t98.\t71 Cox.\t161\t.S3\t218.\t76 Cox.\t7\t00\t28.\t10 Cox.\t6\t.62\t66.\t86 Cox.\t6\t63\t66.\t86 Cox.\tis\t07\t91.\t71 Cox.\t18\t.08\t81\t74 Cox.\t18\t85\t76.\t83 Cox.\t15\t.13\t68\t¦11 Cox.\t16\t.12\t68.\t42 \t12\t24\t113.\tss Hope.\t75\t.09\t115.\t40 \t\t\t12.\t46 Hope.\t\t\t17.\t16 \t\t\t134.\t87 \t17,\tSI\t32.\t50 Municipalité de Port Daniel Est \u2014 Municipality of Port Daniel East Succ.Paul E.Langlois Mde Delima Roy Occup.Pt.276.4 arpents.Du Havre.Port Daniel.$ 27.20 Municipalité de la commission scolaire des Anses \u2014 Municipality of the School Commissioner des Anses Alfred Anglehart.Pt.601.3.Port Daniel.* 135.60 AdverezCyr.,.488.1.Port Daniel.33.45 AdverezCyr.624 .4.Port Daniel.33.45 Succ.Appolinaire Huard.480.1.Port Daniel.143.62 Alcide Morin.Pt.457.Port Daniel.52.38 Mme David Morin.340 A.1.Port Daniel.61.67 Normand Parise.328.1.Port Daniel.162.87 43905-2-2-o Le secrétaire-trésorier, Douglas Smollett.43905-2-2-o Douglas Smollett, Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 119 Municipalité du comté de Châteauguay Avis public est par les présentes donné par le soussigné secrétaire-trésorier du conseil de comté que, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures du matin, à Ste-Martine, dans la salle du Conseil de comté, les immeubles suivants seront vendus pour arrérages de taxes dûs sur chacun de ces immeubles, avec frais encourus, à moins que le tout ne soit payé avant la vente ; Savoir: Municipality of the county of Châteauguay Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer for the Council of the County that THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at Ste-Martine, at TEN o'clock in the morning in the hall of the County Council, the following immoveable properties will be sold for arrears of taxes due on each of these properties, with cost incurred unless paid in full before the sale; To wit: La Corporation Municipale de St-Jean-Chrysostôme The Municipal Corporation of St-Jean-Chrysostôme Propriétaires Owners Numéro du cadastre Cadastral number Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires.School taxes Total Bourdeau, Donat, succ.-est.P.668.S 12.00 t 37.63 S 49.63 Bienvenue, Jean-Claude.P.503.6.37 7.39 13.76 Giroux, Pierrette.30 de 224.4.50 3.30 7.80 Thibault, Claude.562,563,564 .81.65 81.65 La Corporation Municipale du Village de St-Chrysostôme The Municipal Corporation of the Village of St-Chrysostôme Bourdeau, André-Marie.P.792.64.60 S 94.50 $ 149.10 Corporation Municipale de St-Paul de Châteauguay The Municipal Corporation of St-Paul of Châteauguay Perrier, Alfred.48-29, P.48.48.25 48.25 Municipalité scolaire protestante de Châteauguay (Ville Mercier) Protestant School Municipality of Châteauguay (Town of Mercier) Krawec, Ivan.191-P.57.Bauer, Arie Fleisher.28-32- 28.41 12.16 90.36 % 118.77 39.22 51.38 Corporation Scolaire de Châteauguay (Ville de Léry) School Corporation of Châteauguay (Town of Léry) Auger, Léo.301-P.9.Rufiange, Jean-Jacques.P.321.Frappier, E.C.Mme.succ.-est.329-P.17.Frappier, E.C.Mme, succ.-est.329-P.17.Frappier, E.C.Mme, succ.-est.329-22-1.Frappier.Mlle J.329-P.17.Tétrault.J.-Claude.P.335.Primeau, Grégoire.P.336.Faubert.Claude.:.P.353-P.354 Lapierre, Orner, succ-rest.359-3.Lapierre, Orner, succ.-estate.369-2.Mallette, G.H.360-2.Poulliot, Roger.P.367.Bonin, Réal.316-19.Bonin.Réal.325-20.Houlzet-Lacroix, Hélène.P.361.Lavigne, Jean-Pierre.340-13.Gagnon, Bertrand.340-5-6.55.34 S\t47\t.29 S\t102.63 \t59\t.14\t59.14 53.46\t19\t50\t73.02 32.11\t8\t,40\t40.51 18.59\t9\t.69\t28.28 \t18\t.08\t18.08 67.31\t228\t.67\t295.98 60.44\t38\t.61\t98.95 148.69\t50\t59\t205.28 \t11.\t68\t11.62 \t49\t.91\t49.91 \t32\t.37\t32.37 18.51\t363\t.64\t383.16 104.82\t38\t.79\t143.61 2.31\t3\t.78\t6.09 \t24\t.es\t24.68 198.11\t431\t.24\t629.35 486.60\t381\t.16\t867.66 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Corporation Scolaire de Châteauguay (Ville de Léry) (suite) School Corporation of Châteauguay (Town of Léry) (continued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Rochefort, Pierre.344-6.Gagnon, Gilles.344-7.Nadeau, C.345-71.Hudson, Dionne, Jeannine.351-P.1.Alepin, Raymond.353-1.Alepin, Guy.354-1.Woodlands Recreation Ass.32'9rl.Woodlands Recreation Ass.329-23-2, 329-4.Riverdrive Realties Inc.P.303 P.306.Develmrmt.Inn.:.329-17-4'.:.Bellevue Gardens.363-14-16.Bellevue Gardens.353-31.Bellevue Gardens.P.63.Bellevue Gardens.363-29.Bellevue Gardens.353-25.Bellevue Gardens.354-4 & 7.Bellevue Gardens.354-13.Bellevue Gardens.364-25,26,27,29,30.Bellevue Gardens.354-36.Bellevue Gardens.P.354.Imperial Oil Limited.P.363.$ 31.41\t$255\t.76\t$287.17 136.46\t249\t.92\t386.38 29.50\t175\t35\t204.85 97.02\t42.\tOU\t139.08 99.72\t44\t02\t143.74 27.81\t206\t71\t234.52 \t917\t83\t917.83 \t18\t26\t18,26 8.48\t39\t.40\t47.88 17.40\t78\t00\t95.40 4.00\t7\t.65\t11.55 1.12\t1\t50\t2.62 42.84\t8\t.16\t50.99 1.29\t1\t71\t3.00 1.29\t1\t71\t3.00 3.20\t4.\t67\t7.87 1.63\t2\t15\t3.78 8.52\t11\t17\t19.69 1.28\t1\t,63\t2.91 36.51\t8\t15\t44.66 \t29\t15\t29.16 Corporation scolaire de Châteauguay (Châteauguay-Centre) School Corporation of Châteauguay (Town Châteauguay Centre) Giroux, Gérard.P.79._.$ 32.63 $ 32.53 Hatton, L.212-2 .60.57 60.57 Laberge, J.-Guy.59-1-2.18.41 18.41 Laberge, J.-Guy.69-1-1.- 130.61 130.61 McManiman, W., Mme-Mrs.65-97.193 93 193.93 Séguin, Gérard.68-P.04 .44.04 44.04 Fontaine, Claude.58-154.$ 218.82 39.25 258.07 RuseU, William.60-50.911.02 124.39 1,035.41 Rusell, William.60-49 .911.02 124.39 1,035.41 Bordeleau, Léonide.141-187.36.96 36.96 Bordeleau, Léonide.141-176.95.58 95.58 Bordeleau, Léonide.141-187 .57.91 57.91 Lefebvre, Camille.P.141.39.05 39.05 Lefebvre, Camille.141-P.180.6.42 6.42 Laroche, L.142-99.498.94 41.42 540.36 Lardche, L.142-100 .497.36 41.42 538.78 Gadbois, Roland.144-47.89.59 58.44 148.03 Gadbois, Roland.112-74 .675.95 133.28 809.23 Delvechio.W.141-242 .30.06 29.71 59.77 Porat Meir, Arie.141-146 .76.84 36.62 113.46 Porat Meir, Arie.141-147.639.48 47.10 686.58 Dagenais.Jacques.P.150 .328.73 48.59 377.30 Théoret.Roger & uxor.150-26 .707.75 50.95 758.70 Bozan.Peter.150-114-115.376.23 5.32 381.55 Baker, W.E.155-16 .99.07 106.43 205.50 Coutu.Leopold.152-391.209.33 209.33 Martin.André & al.140.662.29 376.46 1,038.74 Klis, Walter.P.176.13.95 13.95 Laberge.Mario.P.224 .68.60 68.60 Labrêche, Albert Jean.162-213 .49.12 32.51 81.63 Labréche, Albert Jeun.248-38-37-3-2-1.3,252.63 7,183.35 10,435.98 Labrêche, Albert Jean.248-320 .266.60 58.87 316.47 Labrêche, Albert Jean.248-321.156.60 63.41 209.91 Labrêche, Albert Jean.248-322.158.08 55.37 213.45 Labrêche, Albert Jean.248-323.159.56 58.69 218.15 Labrêche, Albert Jean.248-324.160.87 60.41 221.28 Labrêche, Albert Jean.248-325.162.35 62.51 224.86 Labrêche, Albert Jean.248-326.162.84 65.00 227.84 Gustainis, V.108-43 .90.18 90.18 Roy, (Raymond Mignonne) Mme.160-204-205.640.65 20.86 661.51 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 197S, Vol.10k, No.S 121 Corporation scolaire de Châteauguay (Châteauguay-Centre) (êuite) School Corporation of Châteauguay (Town Châteauguay Centre) (continued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Karas.S.B.L.141-240.Karas, S.B.L.141-244.TelcoCorp.P.216.Cortina Gardens Inc.60-27.Cortina Gardens Inc.P.65.Ledena Realties Inc.P.59.Admor Const.Inc.152-167.Admor Const.Inc.162-166.Jhonstall Ent.Inc.162-214.Jhonstnll Ent.Inc.152-350.Montery Ent.Inc.160-149.Wing Wong Dev.Co.8.P.176.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.141-9-10.South Shore Gardens Ltd.141-11-12.South Shore Gardens Ltd.141-15-16.South Shore Gardens Ltd.141-17-18.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Lrd.141-32-33.South Shore Gardens Ltd.141-26-26.South Shore Gardens Ltd.141-27-28-29.South Shore Gardens Ltd.P.141-141-48.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.141-123.South Shore G ardens Ltd.141-333-67.South Shore Gardens Ltd.141-65-66.South Shore Gardens Ltd.141-63-64.South Shore Gardens Ltd.141-40-41.South Shore Gardens Ltd.141-37-38-39.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.141-175.South Shore Gardens Ltd.141-135.South Shore Gardens Ltd.141-136.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.South Shore Gardens Ltd.P.141.Vincenzo de Villes.223-112.Jacques Marc Dev.Inc.P.21 (4-28-26).Jacques Marc Dev.Inc.P.21 (4-45-1).West Drive.226-P.1076.Châteauguay Ready Mix.226-P.1369.Welmo Const.Ltd.4 al.P.220.Immeubles Bolem Inc.248-52.89,842.65 Depositors Mortgage.P.248.Dumont Dev.Corp.Damage Inv.Corp.f Damase Inv.Corp.:.J?'ioo Damase Inv.Corp.{, ,5?Damase Inv.Corp.P.J21.Damase Inv.Corp.- TïL.Verdi Dev.Corp.JÎH29.Verdi Dev.Corp.l}5-98.Verdi Dev.Corp.JîfiSÀ Verdi Dev.Corp.116-200.S 123.40\tS 92\t88\t8 216.40 133.30\t117\t29\t260.59 \t1,462\t.92\t1.462.92 108.80\t55\t.68\t164.48 3.62\t2\t.00\t6.61 2,115.35\t2,244\t.69\t4,360.04 217.37\t49\tS 5\t267.24 217.39\t49\t85\t267.24 49.60\t41\t51\t91.01 40 04\t36\t.04\tsr.\"s 36.88\t11\t.44\t61.32 \t14\t14\t14.14 Mît 1.7\t145\t69\t1,009.36 208.68\t26\t01\t234.69 150.26\t21\t21\t171.47 48.52\t34\t02\t83.14 48.52\ta 4\t02\t83.14 48.52\t34\t62\t83.14 48.52\t34\t62\t83.14 142.08\t94\t86\t236.94 si 5.s3\t206\t¦15\t1,052.28 1,033.18\t287\t10\t1,320.34 718.49\t94\t08\t812.62 39.44\t23\t1)0\t62.44 39.44\t23\t00\t62.44 59.17\t34\t55\t93.72 102.62\t5'.'\t83\t102 -15 134.11\t75\t76\t209.87 44.82\t25\t43\t70.25 63.10\t36\t84\t99.14 39.43\t23\t00\t62.44 39.44\t23\t00\t62.44 39.44\t23\t00\t62.44 39.44\t23\t00\t62.44 59.17\t34\t88\t93.72 674.87\t105\t88\t780.52 121.08\t67.\t¦15\t188.63 39.44\t23\tm\t62.44 47.33\t27.\tGO\t74.99 39.44\t83\t00\t62.44 39 44\t23\t0O\t62.44 105.26\t61.\t48\t166.74 443.72\t88\t02\t531.74 255.87\t40\t85\t296.72 47.33\t27\t95\t75.28 223.43\t120\t68\t350.11 615.05\t352\t88\t965.16 43.38\t25.\t30\t68.68 216.98\t79\t37\t296.35 870.45\t536\t08\t1.406.64 361.26\t29\t38\t390.64 8,688.61\t1.109\t08\t9,797.64 5,446.69\t1,855\t50\t7.702.25 10.95\t17\tso\t28.81 \t729.\t86\t729:96 9,073.71\t6.163\t26\t15,236.97 22,342.65\t9.720\t08\t32,062.73 483.47\t9\t.17\t492.64 717.26\t148\t.19\t865.45 796.64\t249\t31\t1,045.95 794.08\t252\t.84\t1,046.92 2,940.16\t597\t.68\t3,537.84 1,738.62\t396\t.13\t2,134.75 1,814.41\t826\t80\t2.640.61 128.12\t95\t.75\t223.87 107.78\t79\tS 5\t187.63 87.05\t67\t.SI\t154.66 76.35\t50\t.15\t136.40 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10i' année, n° 2 Corporation scolaire de Châteauguay (Châteauguay-Centre) (suite) School Corporation of Châteauguay (Town Châteauguay-Centre) (continued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Verdi Dev.Corp.115-197.Verdi Dev.Corp.115-106.Verdi Dev.Corp.115-167.Verdi Dev.Corp.115-203.Verdi Dev.Corp.115-194.Verdi Dev.Corp.115-P.196.Verdi Dev.Corp.115-124.Verdi Dev.Corp.115-192.Verdi Dev.Corp.115-191.Verdi Dev.Corp.115-187.Verdi Dev.Corp.P.116.Verdi Dev.Corp.115-188.Verdi Dev.Corp.116-189.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.116-163.Verdi Dev.Corp.116-128.Verdi Dev.Corp.116-148.Verdi Dev.Corp.115-159.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.P.115.Verdi Dev.Corp.115-369.Verdi Dev.Corp.P.115.United Dev.Corp.121-256.United Dev.Corp.121-257.United Dev.Corp.121-258.United Dev.Corp.121-259.United Dev.Corp.121-260.United Dev.Corp.121-261.United Dev.Corp.121-262.United Dev.Corp.128-61.United Dev.Corp.128-84.United Dev.Corp.122-22/128-83.United Dev.Corp.121-269.United Dev.Corp.121-268.United Dev.Corp.121-267.United Dev.Corp.121-264/128-59.United Dev.Corp.128-63.United Dev.Corp.128-64.United Dev.Corp.128-93.United Dev.Corp.128-87.United Dev.Corp.128-85.United Dev.Corp.128-88.Park View Const.Ltd.P.170.$ 175\t75\t$ 129.69\t8 305.34 229\t25\t179.96\t407.21 694\t.80\t108.33\t803.13 446\t66\t96.04\t542.69 446\t65\t96.04\t542.69 663\t70\t127.14\t720.84 711\t.22\t82.54\t793.76 469\t40\t89.46\t658.86 450\t38\t124.07\t674.45 657\t.79\t99.93\t757.72 438\t.93\t66.90\t505.83 672\t.62\t126.42\t799.04 898\t80\t127.11\t1,025.41 445\t59\t71.82\t517.41 445\t59\t71.82\t517.41 445\t59\t71.82\t517.41 445\t59\t71.82\t517.41 769\t.69\t92.21\t851.90 759\t.69\t92.21\t851.90 636\t29\t92.21\t728.50 636\t.20\t92.21\t728.60 444\t.42\t3.07\t447.49 4,953\t.47\t172.68\t5,126.15 440\t.18\t17.13\t457.31 86\t56\t15.34\t100.90 7\t.66\t5.80\t13.36 126\t.17\t3.82\t128.99 125\t.17\t3.82\t128.99 192\t.50\t4.45\t196.95 192\t50\t4.45\t196.95 190\t.18\t3.81\t193.99 126\t.17\t3.81\t128.99 125\t17\t12.28\t138.45 283\t01\t13 55\t297.16 247\t.97\t14.92\t262.89 \t\t4.24\t4.24 \t\t3.88\t3.88 \t\t4.50\t4.60 \t\t29.73\t29.73 196\t.08\t15.80\t211.88 125\t17\t12.29\t137.46 144\t.82\t12.29\t157.11 111\t82\t12.29\t157.11 222\t68\t15.60\t238.18 125.\t17\t12.29\t137.46 32\t70\t40.78\t73.48 Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) School Corporation of Châteauguay (Town of Châteauguay) Simard, R.278-438.Camera, Tito.253-50.Camera, Tito.253-59.Camera, Tito.254-637.Carriera, Tito.254-638.Markues.José.254-095.Tougas, M.G.254-05.Soares, M.A.254-203.Soares, M.A.254-302.Soares, M.A.254-201.Béasse, D.1-34-2.Benoit, J.G.5-189-190 P.191.Yergeau, G.56-76-77.Yergeau, Q.56-78-79.De Cesare.M.T.Mile-Miss.56-508., Grenier, M.50-363.*\t39.80 $\t39.80 38.40\t8.43\t46.83 38.14\t0.47\t38.61 397.83\t39.43\t437.26 456.06\t4.17\t460.23 \t18.24\t18.24 393.85\t39.18\t433.03 26.58\t24.29\t60.87 25.99\t24.29\t50.28 39.90\t37.36\t77.26 117.46\t21.47\t138.93 291.16\t183.64\t474.80 512.51\t97.45\t609.96 510.64\t69.76\t580.40 189.69\t42.99\t229.68 \t44.80\t44.80 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 123 Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) (tuile) School Corporation of Châteauguay (Town of Châteauguay) (continued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Anderson, D.50-356.Allard, Jhon.17-646.Wodon.V.20-175-176.-.Lavigne, CécUe.Mme-Mrs.47-106.Lavigne, Cécile, Mme-Mrs.47-107.Lavigne, Cécile, Mme-Mrs.44-367-368-369-370.Lavigne, Cécile, Mme-Mrs.44-398-399-400.Lavigne, CécUe, Mme-Mrs.401-402-403.Lavigne, Cécile, Mme-Mrs.44-395-396-397.Lavigne.CécUe.Mme-Mrs.389-390-391.Lavigne.Cécile, Mme-Mrs.44-392-393-394.Martin.A.1-P.513.Laberge.J.-Arthur.47-117-118-119.Lagardc, G.-E.17-254-255-256-257-258-259.Lagarde, G.-E.17-299.Bourdeau, C.47-10.Caouette, R.17-248 à 308.Les Placements V.Marie Ltée.279-176.Les Placements V.Marie Ltée.279-177.Les Placements V.Marie Ltée.279-178.Les Placements V.Marie Ltée.279-179.Les Placements V.Marie Ltée.279-180.Châteauguay Beach Hotel.P.294-295-65-294-1 L'Aiguillon Ltée.290-P.3.L'Aiguillon Ltée.P.293.L'Aiguillon Ltée.P.293.Riverdrive Realty Inc.279-116.Bokor Holdings Ont.Ltd.253-301-2.Bokor Holdings Ont.Ltd.254-282.Bokor Holdings Ont.Ltd.254-606.Riverdrive Housing & Land Corp.254-P.130.Riverdrive Gardens Inc.253-294.Riverdrive Gardens Inc.253-293.Riverdrive Gardens Inc.257-P.78-79-P.80 Riverdrive Gardens Inc.257-88-2.Riverdrive Gardens Inc.253-317.Riverdrive Gardens Inc.253-318.Riverdrive Gardens Inc.254-P.659-657.Riverdrive Gardens Inc.253-47.Riverdrive Gardens Inc.254-656.Riverdrive Gardens Inc.253-R305.Riverdrive Gardens Inc.253-308.Riverdrive Gardens Inc.257-P.182.Riverdrive Gardens Inc.253-182.Riverdrive Gardens Inc.254-P.527.Riverdrive Gardens Inc.254-503.Riverdrive Gardens Inc.254-502 .Riverdrive Gardens Inc.253-P.83.Riverdrive Gardens Inc.253-P.80.Riverdrive Gardens Inc.254-P.188.Riverdrive Gardens Inc.253-181.Riverdrive Gardens Inc.254-569/257-229 Riverdrive Gardens Inc.264-686.Riverdrive Gardens Inc.264-153.Riverdrive Gardens Inc.254-147 .Riverdrive Gardens Inc.253-P.138.Riverdrive Gardens Inc.253-154.Amdon Realties Inc.2sHiî.Amdon Realties Inc.254-501.Amdon Realties Inc.253-82.Amdon Realties Inc.253-81.Amdon Realties Inc.254-405.Amdon Realties Inc.253-161.Amdon Realties Inc.253-162.Amdon Realties Inc.253-103.Amdon Realties Inc.263-164.\tS 212.56\tS 212.56 \t41.05\t41.05 251.04\t27.26\t278.30 \t37.63\t37.63 \t53.60\t53.60 \t43.33\t43.33 \t60.45\t60.45 \t33.07\t33.07 \t489.15\t489.16 17.82\t11.40\t29.22 92.50\t49.04\t141.54 494.39\t47.33\t541.72 46.58\t12.53\t59.11 \t22.55\t22.55 rala\\\t118.61\t118.61 raisj 379.57\tS 25.44\tt 405.01 376.90\t25.44\t402.34 276.90\t25.44\t402.34 376.90\t25.44\t402.34 276.90\t25.44\t402.34 748.64\t1,149.36\t1,898.30 85.69\t70.10\t165.19 319.05\t274.70\t593.75 69.68\t56.99\t126.67 216.03\t27.05\t243.08 233.55\t18.03\t251.58 39.33\t19.53\t58.86 43.76\t25.54\t69.03 39.14\t19.53\t58.67 424 on\t33.06\t457.12 423.40\t33.06\t456.46 543.08\t51.10\t594.18 183.04\t10.51\t193.55 63.82\t31.55\t95.37 03 82\t31.55\t95.37 35 88\t18.03\t53 91 571.94\t45.07\t617.01 532.16\t42.07\t574.23 113.45\t18.03\t131.48 335.67\t40.56\t376.23 143.05\t7.12\t150.17 39.33\t15.77\t55.10 18.77\t9.01\t27.78 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 18.77\t9.01\t27.78 24.46\t12.02\t36.48 18.77\t9.01\t27.78 39.33\t19.53\t58 80 56.85\t28.55\t85.40 60.62\t30.05\t90.67 60.62\t30.05\t90.67 56.85\t2- 55\t85.40 15.43\t7.60\t22.93 45.19\t22.53\t67.72 40.01\t19.53\t59.54 39.33\t19.53\t58.86 45.19\t22.63\t67.72 45.19\t22.53\t67.72 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t4.37\t43.70 39.33\t23.50\t62.83 39.33\t23.50\t62.83 39.33\t4.37\t43.70 124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 101' année, n° S Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) (auile) School Corporation of Châteauguay (Town of Châteauguay) (ocntinued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Amdon Realties Inc.253-165.Amdon Realties Inc.253-166.Amdon Realties Inc.253-167 .Amdon Realties Inc.254-470.Amdon Realties Inc.254-387.Amdon Realties Inc.254-678 Zeus Corp.254-372.Zeus Corp.254-371.Zeus Corp.254-370.Zeus Corp.254 360.Zeus Corp.254-235 Zeus Corp.254-234.Zeus Corp.254-233.Zeus Corp.254-262.Zeus Corp.254-263 .Zeus Corp.254-264 Zeus Corp.254-265 Zeus Corp.254-266 Zeus Corp.254-294 Zeus Corp.254-293.Zeus Corp.254-292.Zeus Corp.254-291.Zeus Corp.254-290.Zeus Corp.254-289.Zeus Corp.254-288.Zeus Corp.254-281.Zeus Corp.254-280.Zeus Corp.254-279.Zeus Corp.254-278 .Zeus Corp.254-277 .Zeus Corp.254-276.Zeus Corp.254-275.Zeus Corp.254-273.Zeus Corp.254-272.Zeus Corp.254-312.Zeus Corp.254-313.Zeus Corp.254-314.Zeus Corp.254-315.Zeus Corp.254-316.Zeus Corp.254-317 .Zeus Corp.254-318.Zeus Corp.254-319.Zeus Corp.254-320.Zeus Corp.254-321.Zeus Corp.254-322 .Zeus Corp.254-323.Zeus Corp.254-324.Zeus Corp.254-325.Zeus Corp.254-326 Zeus Corp.254-327 Zeus Corp.254-328.Zeus Corp.254-329.Zeus Corp.254-330.Zeus Corp.254-331.Zeus Corp.254-332.Zeus Corp.254-333.Zeus Corp.254-334 Zeus Corp.254-335.Zeus Corp.254-336.Zeus Corp.254-337.Zeus Corp.254-391.Zeus Corp.254-390.Zeus Corp.\u2022.254-389.Zeus Corp.254-388 Zeus Corp.254-361.Zeus Corp.254-360.Zeus Corp.254-359.Zeus Corp.254-358.$ 39.33\tS 13.95\tS 53.28 39.33\t4.37\t43.70 39.33\t22.53\t61.86 63.46\t27.05\t80.51 51.14\t25.55\t76.69 24.51\t12.02\t36.53 40.32\t23.91\t64.23 39.33\t32.93\t72.26 39.33\t23.91\t63.24 30.33\t32.93\t72.26 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 36.28\t18.40\t54.68 39.33\t19.19\t68.52 45.19\t22.17\t67.36 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19, 19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t5S.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\tÔS.52 39.33\t19.19\t58.52 42.16\t20.65\t62.81 36.28\t17.70\t53.98 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t68.62 39.33\t19.19\t68.62 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10i, No.2 125 Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) (tuile) School Corporation of Châteuuguay (Town of Châteauguay) (continued) Propriétaires Owners Numéro du cadastre Cadastral number Taxes\tTaxes\t munie.\tscolaires\t \t\tTotal Munie.\tSchool\t taxes\ttaxes\t g 39.33\tS 19.19\t$ 68.62 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t68.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t68.62 56.85\t28.04\t84.89 63.27\t26.58\t79 85 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 39.33\t19.19\t58.52 39.33\t19.19\t58.62 474.82\t36.06\t610.88 211.89\t16.52\t228.41 637.86\t39.06\t676.92 387.57\t30.05\t417.62 423.31\t36.06\t459.37 277.20\t27.05\t304.25 331.59\t12.02\t343.61 531.32\t22.55\t553.87 175.87\t22.55\t198.42 272.78\t24.05\t296.83 74.11\t43.58\t117.69 63.82\t31 55\t95.37 67.41\t28.54\t86.96 626.29\t31.55\t667, 84 48.10\t26.00\t74.10 297.20\t36.07\t333.27 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 41.98\t21.03\t63.01 39.33\t19.53\t58.si, 39.33\t19.53\t58 SI, 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58 N6 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t49.30\t.88 c:i 39.33\t19.53\t58 SI, 39.33\t19.53\t68 88 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 2,894.11\t309.27\t3,203.38 39.33\t12.18\t61.61 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t5s.se, 39.33\t19.33\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.53\t19.53\t58 .80 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.80 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58 .SI, 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 36.69\t18.03\t54.62 39.33\t19.53\t58 .SI', 39.33\t19.53\t5s se, 45.19\t22.53\t67.72 39.33\t19.53\t68.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t68.86 Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeue Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Zeus Corp.Palese Inv.Ltd.Palcse Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.I ' .i' ¦ Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Paleso Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.Palese Inv.Ltd.254-357.254-356.254-355.254-354.254-353.254-352.254-351.254-350.254-349.254-348 .254-347.254-346.254-345.254-344.254-343 253-300-2-1,' 301-1 '.'.Y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.253-297-2.253-297-1/253-296.254-635-13.254-635-2/635-6-1/635-7-1.253-288-2-289.254-635-14, 635-13.257-72.257-89-1.90-1.257-89-2/90-2.257-98.257-110.,.P.257.253-310.254-660.254-663-664-665.254-666-667.254-304.254-412.254-520.254-518/257-234.254-516.254-515.254-514.254-513.254-509.254-508.254-507.254-506.254-505.254-504.254-492.254-491.254-490.254-489.P.254-253/P.24.254-635-31.254-635-30.264-636-29.254-635-28.254-635-27.254-635-26.254-427.254-426.,.254-181.254-187.254-190._.254-191.-.254-206.-.254-210.254-209.253-272._.253-273.253-274.253-275.-. 126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n° S Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) (suite) School Corporation of Châteauguay (Town of Châteauguay) (continued) Taxes Taxes Propriétaires Numéro du cadastre munie.scolaires Total Owners Cadastral number Munie.School taxes taxes Palese Inv.Ltd.253-276.Palese Inv.Ltd.253-277.Palese Inv.Ltd.253-278.Palese Inv.Ltd.253-279.Palese Inv.Ltd.253-280.Palese Inv.Ltd.253-281.Palese Inv.Ltd.253-282.Palese Inv.Ltd.254 297/253-225.Palese Inv.Ltd.253-270.Palese Iuv.Ltd.253-209.Palese Inv.Ltd.253-268.Palese Inv.Ltd.253-267.Palese Inv.Ltd.254 467/253-266.Palese Inv.Ltd.254-468.Palese Inv.Ltd.254-469.Palese Inv.Ltd.254-471.Palese Inv.Ltd.254-472.Palese Inv.Ltd.254-473.Palese Inv.Ltd.254-474.Palese Inv.Ltd.254-475.Palese Inv.Ltd.254-476.Palese Inv.Ltd.254-477.Palese In v.Ltd.254-478.Palese Inv.Ltd.254-479.Palese Inv.Ltd.254-480.Palese Inv.Ltd.254-481.Palese Inv.Ltd.253-260.Palese Inv.Inc.253-261.Palese Inv.Inc.253-262.Palese Inv.Inc.253-263.Palese Inv.Inc.253-264.Palese Inv.Inc.254-463/263-265.Palese Inv.Inc.254-464.Palese Inv.Inc.254-465.Palese Inv.Inc.254-457.Palese Inv.In8.254-448.Palese Inv.Inc.254-447.Palese Inv.Inc.,.253-248.s.Palese Inv.Inc.253-249.Palese Inv.Inc.253-250.Palese Inv.Inc.253-251.Palese Inv.Inc.253-252.Palese Inv.Inc.254-463 /2S3-253.Palese Inv.Inc.254-464.Palese Inv.Inc.264-455.Palese Inv, Inc.264-466.Palese Inv.Inc.:.253-269.Pa.ese Inv.Inc.264-694.Palese Inv.Ino.253-258.Palese Inv.Inc.253-257.Palese Inv.Inc.253-256.Palese Inv.Inc.253-255.Palese Inv.Inc.254-462/253-254.Palese Inv.Inc.254-461.Palese Inv.Inc.254-460.Palese Inv.Inc.253-237.Palese Inv.Ino.253-238.Palese Inv.Inc.253-239.Palese Inv.Inc.253-240.Palese Inv.Inc.254-445/253-241.Palese Inv.Inc.254-444.Palese Inv.Ino.254-443.Palese Inv.Ino.254-442.Palese Inv.Inc.254-441.Palese Inv.Inc.254-440.Palese Inv.Inc.254-246.Palese Inv.Inc.253-245.Palese Inv.Inc.253-244.t 39.33\tS 19.63\t$ 58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 33.39\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 327.00\t165.31\t492.31 45.19\t22.53\t67.72 45.19\t22.53\t07.72 45.19\t22.53\t67.72 45.19\t22.53\t67.72 45.19\t26,48\t71.67 47.87\t24.05\t71.92 53.46\t27.05\t80.51 42.16\t21.05\t63.21 39.33\t19.53\t58.86 .39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 42.16\t21.03\t63.19 39.33\t10.29\t49.62 39.23\t10.29\t49.62 39.33\t10.29\t49.62 39.33\t10.29\t49.62 39.33\t10.29\t49.62 39.33\t13.02\t62.35 39.33\t10.29\t49.62 36.28 \u2022\t11.56\t47.84 45.19\t22.53\t67.72 60.62\t30.05\t90.67 48.23\t12.66\t60.89 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t68.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t68.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t68.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t68.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.53\t68.86 .39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.53\t68.86 39.33\t19.53\t58.86 39.33\t19.63\t68.86 39.33\t19.63\t58.86 39.33\t19.63\t68.86 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10i, No.2 127 Corporation scolaire de Châteauguay (Ville de Châteauguay) (lutte) School Corporation of Châteauguay (Town of Châteauguay) (continued) Propriétaires Owners Numéro du cadastre Cadastral number Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Total Palese Inv.Inc.253-243.'.Palese Inv.Inc.254-452 /253-242.Palese Inv.Inc.254-451.Palese Inv.Inc.254-450.Palese Inv.Inc.254-449.Palese Inv.Inc.254-243.Palese Inv.Inc.254-242.Palese Inv.Inc.254-241.Palese Inv.Inc.254-240.Palese Inv.Inc.254-239.Palese Inv.Inc.254-238.Palese Inv.Inc.254-237.Palese Inv.Inc.254-236.Palese Inv.Inc.254-232.Palese Inv.Inc.254-231.Palese Inv.Inc.254-230.Palese Inv.Inc.254-229.Palese Inv.Inc.254-228.Pidese Inv.Inc.254-249.Palese Inv.Inc.254-250.Palese Inv.Inc.254-251.Palese Inv.Inc.254-252.P:dese Inv.Inc.254-253.Palese Inv.Inc.254-254.Palese Inv.Inc.254-255.Palese Inv.Inc.254-256.Palese Inv.Inc.254-257.Palese Inv.Inc.254-258.Palese Inv.Inc.254-259.Palese Inv.Inc.254-260.Palese Inv.Inc.254-261.Palese Inv.Inc.254-398.Palese Inv.Inc.254-397.Palese Inv.Inc.254-396.Palese Inv.Inc.254-395.Palese Inv.Inc.254-394.Palese Inv.Inc.254-393.Palese Iny.Inc.254-392.- Palese Inv.Inc.,.254-274.Palese Inv.Inc.254-554.Palese Inv.Inc.254-P.553.Palese Inv.Inc.254-P.553.Palese Inv.Inc.254-552.Palese Inv.Inc.254-580.Palese Inv.Inc.257-232/254-522.Palese Inv.Inc.'.254-683.Palese Inv.Inc.254-693.Palese Inv.Inc.254-694.Palese Inv.Inc.;.254-679.Palese Inv.Inc.¦.254-146.Palese Inv.Inc.,.254-162.A sud 62,.£ 82.3C-H 116.3C-H 63.2A-141.2 A-188____ 3C-68.3C-205.2A-270____ 2A-H 145.2A-62.2A-252.P 3A 3À-52a 3A-60.'.\"! 3A-37 à 3A-41.Rang Range\tAcres\tTaies mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tIntérêt Interest\tTotal 13.13 14.13.13.\t5000 p.c____ 5000 p.c____ 10000 p.c.5120 p.c____\tS 3.60 6.00 3.60\tS 9.06 15.50 24.16 9.48\t$ 3.30 6.79 3.51 3.34\t$ 15.96 27.29 27.67 16.42 13 12.13.13.14.\t10730 p.c.11825 p.c.9914 p.c____\t6.00\t97.73 63.42 16.23 76.68\t8.66 5.76 4.15 7.07\t106.39 69.18 26.38 83.75 13.13.\t0007 p.o____ 10000 p.c.\t\t9.48 27.27\t1.98 2.57\t11.46 29.84 13.\t7450 p.c____\t\t17.68\t2.41\t19.99 13\t5580 p.c.\t6.00\t16.35\t5.25\t27.60 13.\t7450 p.c.\t6.00\t6.44\t3.34\t16.78 13.\t5000 p.c-\t3.60\t17.58\t3.76\t24.94 14.\t10500 p.c.\t\t15.59\t2.21\t17.80 13.\t5007 p.c.\t3.60\t17.58\t3.76\t24.94 13.\t5000 p.c____\t3.60\t17.58\t3.76\t24.94 13.\t6805 p.c.\t\t16.36\t2.41\t18.76 13\t5000 p.c.\t3.60\t16.35\t3.76\t23.71 13.\t4955 p.c____ 7542 p.c.\t3.60\t17.40\t3.76\t24.76 13.\t\t9.60\t\t3.94\t13.64 13.\t\t3.60\t9.69\t3.55\t16.64 14.\t7625 p.c.3888 p.c.14770 p.c.3770 p.c____\t7.20\t12.08\t6.13\t24.41 13.13.\t\t3.60\t21.77 9.06\t3.34 3.30\t25.11 15.96 13.\t11502 p.c.\t\t29.42\t4.14\t33.56 13.\t11690 p.c.\t6.00\t36.49\t4.03\t46.62 13 13.13.\t\t480.80\t480.54\t89.26\t1.050.60 Corporation Municipale du Village d'Omerville (Bolton) Municipal Corporation of the Village of Omerville (Bolton) Roméo Custeau.\tP.3.\t20\t80 ac .\t* 56.00\tS 11\t66\t$ 10\t90\t* 78\t4.1 Jean-Claude Faucher.\t2C-45____\t20.\t\t\t\t\t\t\t\t (Mme Ernest Roy).\t2C-50.\t19\t\t55.61\t43\t20\t7\t49\t106\t30 \t2D-90.\t20.\t\t234.78\t341\t43\t46\t00 86\t622\t21 \t2D-27.\t20.\t7500 p.c____\t84.48\t70\t04\t11\t\t166\t38 \t1-119.\t20.\t7500 p.o.7500 p.c.\t\t\t\t\t\t\t \t1-123.\t\t7600 p.c____\t\t\t\t\t\t\t \t1-124.\t20.\t7500 p.c____\t91.10\t49\t48\t13\t85\t154\t43 Julien Proulx\t1-240.\t20.\t7500 p.c____\t70.00\t171\t71\t26\t08\t267\t79 (André Trottier Syndic).\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.3 149 Municipalité de Ste-Catherine de Hatley Municipality of St.Catherine^de Hatley Occupants Miss Mae Bean.Chas.B.Bergland.Herbert Gunther.John T.Haxall (succ.-est.Gordon).Albert Madore.Dame Louisette Saraschi.Rev.F.Toope., Claude Laplante a/s Curateur Public.Jospeh Laposhnyik.Township Playhouse Guild Inc.W.Alexander, Abba Dev.Inc.R.Charron, Abba Dev.Inc.Claude Codère, Abba Dev.Inc.W.Levasseur, Abba Dev.Inc.Kart Pockrant., Lots cad.Cad.lots P.996.P.950.P.1154.P.1154.P.943.1154-15.1154-16.1247-5.P.1154.P.1157.1361-60.1361-83.P.920.P.1157.1154-32.P.1158.1157-13.1157-14.1157-15.1154-12.1154-20.Rang Range Acres 6.\t11250 p.c.6\t 8.\t8000 p.c.\t8000 p.c____ 6.\t16A.8.\t12834 p.c.\t12997 p.c.8.\t13166 p.c.8.\t10600 p.c.\t200 p.c.9.\t9755 p.c.9.\t8789 p.c____ 6.\t 8.\t9314 p.c____ 8.\t14807 p.c.8.\t9500 p.c .8\t14561 p.c.\t14549 p.c.\t14708 p.c.\t10210 p.c.\t8031 p.c____ Taxes mun.Mun.taxes\tTaxes scol.School taxes\tIntérêt Interest\tTotal 28.19\t$ 107.12\tS 8.54\t$ 143.85 \t241.63\t12.27\t253.90 \t41.15\t2.07\t43.22 9.60\t50.89\t3.63\t64.12 37.80\t92.99\t8.08\t138.87 \t23.91\t1.75\t25.66 56.80\t03.07\t10.30\t130.77 13.64\t38.51\t6.55\t58.70 \t57.11\t5.95\t63.06 \t829.04\t77.31\t906.35 \t43.30\t4.75\t48.05 \t33.38\t3.85\t37.23 6.46\t21.42\t3.50\t31.38 32.62\t27.22\t4.53\t64.37 45.10\t\t4.50\t49.60 Corporation du Canton de Hatley Ouest Corporation of the Township of Hatley West A.W.Roddick.Mrs.Phyllis Stark.\t979-19-20.P.809, P.834.\t6.5.\t\tS 33.00 90.54\t$ 65.66 11.42 312.54\tS 2.40 1.04 20.13\t$ 101.06 12.46 423.21 \tP.646.\t4.\t\t\t\t\t Municipalité de Beebe Plain \u2014 Municipality of Beebe Plain\t\t\t\t\t\t\t \t4.\t\t\tS 2.30\t\t\tS 2.30 Municipalité de Ayers' Cliff \u2014 Municipality of Ayers' Cliff\t\t\t\t\t\t\t Mrs.Evelyn Lafond .Harvey B.Lawrence.Grant Smith.Carol! Whipple.\tP.1009-3.P.1264.P.1057.P.1024.\t\t\t8 74.00 28.00 56.80\t8 220.32 83.36 16.77 35.74\tS 13.56 6.58 1.51 12.30\t$ 307.88 117.94 18.28 94.84 Corporation Municipale du Canton de Hatley Municipal Corporation of the Township of Hatley Grant Smith.Dame W.Page, Jr.Dame W.Page, Jr.Stanley MacDonald.W.S.Richardson.Mrs.Russell Suitor.Mrs.Catherine Tarte.Entreprise du Mont Chesham Pierre Turcotte.Arthur Carrier.P.590, P.591.603-1,-2, -3, P.4.602-1-602-2.615-616-617.640-10.P.642.P.642.469-471.P.470.286.239-8, 553-80.P.204.3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 20.54\tS 175.36 \t169.75 \t58.35 21.49\t101.71 \t94.64 3.06\t26.68 28.62\t102.16 19.76\t108.86 13.23\t 25.87\t 150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Corporation du Village de Stanstead Plairi Corporation of the Village of Stanstead Plain Occupants\tLots cad.Cad.lots\tRang Range\tAcres\tTaxes mun.Mun.taxes\tTaxes sco!.School taxes\tIntérêt Interest\tTotal Lennoxvilh Building Supplies & Wm.Aulis.\t\t\t\t\tS 26.05\t$ 2.46\t$ 28.51 Municipalité de Stanstead Est \u2014 Municipality of Stanstead East\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t2 .\t$ 15.00\tS 12.60 84.83\tS 0.35 0.35\tt 12.95 100.18 Wesley Morrow.\tP.973.\t12.\t5/8.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Mathieu de Dîxville \u2014 Municipality of St.Mathieu de Dixville\t\t\t\t\t\t\t Morris Balwin.Thomas Hart, vendu le 25 mai 1971 à Arlene Lyon et Joseph Andrew.\tP.15G.P.14D.P.17V.15B-16d-16d-2.\t7.1.1.\t\t\tS 100.16 11.98 181.40\t$ 4.31 1.67 10.20\tS 104.47 13.65 191.60 Municipalité de St-Herménégilde \u2014 Municipality of St.Herménégilde\t\t\t\t\t\t\t Marcel Bélanger.\tP.5A-5B.P.5C-5d.\t7.\t300.\tS 84.82 29.32\tS 149.66 93.14\tS 1.34 3.28\t$ 235.82 125.74 \tP.6A-6B.P.25 sud.\t1.\t50 x 122.\t\t\t\t Les Commissaires d'Écoles pour la Municipalité de Coaticook School Commissioners of the Municipality of Coaticook\t\t\t\t\t\t\t Les Entreprises Roy Ltée.J.A.Madore.Mme Antoinette Désorcy (Guimond).Raymond E.Dubois.\t770-2.685-1, 686-1, 685-2, 685-3, 684-2.P.16-11.P.28B.P.25 sud.5A-5B-5C-5D-6A-6B.1640, 2095.\t4.8.1.7.\t\t\t» 163.68 1,367.15 17.91 2.70 149.66 93.14 13.96\t3 7.76 71.38 6.03 1.05 1.34 3.28 1.16\tS 171.44 1,438.53 23.94 3.75 151.00 96.42 15.12 \t\t\t\t\t\t\t Toutes les surfaces ou autres dimensions indiquées ci-dessus sont données plus ou moins.Donné et daté à Barnston, P.Q., ce 31e jour de décembre 1971.Le secrétaire-trésorier, 43943-2-2-0 Robert Breault.AU surface or other dimensions hereinabove indicated are more or less.Given and dated at Barnston, P.Q., this 31st day of December, 1971.Robert Breault, 43943-2-2 Secretary-Treasurer.Municipalité du Comté de Shefford Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de Shefford, que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique, à l'Hôtel de Ville de Waterloo, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts, plus les frais subséquents encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.Municipality of the County of Shefford Public notice is hereby given by the undersigned Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the county of Shett'ord, that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of Waterloo, on THURSDAY, the NINTH dav of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.101, No.2 151 La Commission municipale de Québec, par décision en date du 20 novembre 1968, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles, sous l'autorité de la Loi du Code Municipal, article 730.The Québec Municipal Commission, by a decision dated November 20, 1968, has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immovables under the authority of article 730 of the Municipal Code.Municipalité du village de Ste-Prudentienne \u2014 Municipality of the village of Ste-Prudentienne Noms Names\tLots\tCanton Township\tRg-rue Rge-St.\tTaxes Munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \t\t\tPrincipale.\t$ 42.72\t8 91.02\t\tS 133.74 Paroisse Ste-Prudentienne \u2014 Ste-Prudentienne Parish\t\t\t\t\t\t\t \tP.5C.\tMilton.\t1.\tS 14.07 36.00\tS 65.41 4.10\t\t$ 69.48 40.10 Lalumière, Paul .\tp.S-1B.\t\t10.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Bonsecours \u2014 Municipality of Bonsecours\t\t\t\t\t\t\t \t985, 986, 1053, 1054, 1055, 1056.\tStukely.\t10 et 11.\t3 112.28\t\t\t$ 112.28 Municipalité de Maricourt \u2014 Municipality of Maricourt\t\t\t\t\t\t\t \t643, 644, 645, P.S.647, 742.743.745.P.746.106.108\tEly Nord.Ely Nord\t7 et 8.\tS 491.19 46.85\t$ 699.45 81.47\t\t$ 1,190.64 128.32 Commission scolaire Valcourt \u2014 School commission of Valcourt\t\t\t\t\t\t\t Pépin, Ulric.Villeneuve, Fernand.\tP.289.616.719, 617, 721, 722.273, P.265, 269.177, 256.P.548.\tEly.Ely.Ely.Ely.Ely.\t\t\t$ 32.93 316.48 73.11 125.27 24.69\t\t8 32.93 316.48 73.11 125.27 24.69 Municipalité de Ste-Anne de la Rochelle \u2014 Municipality of Ste-Anne de la Rochelle\t\t\t\t\t\t\t \tP.740.P.510 et P.513.\tStukely.Stukely.\t9.5.\t$ 3.08 0.60 0.60 2.56\t$ 17.42 15.64 11.73 17.42\t$ 3.32 3.32 3.32 3.32\t$ 23.82 19.56 15.65 23.30 Jones, Dr.Barbara.Schier, Yvonne (Mr.John Schier).\tP.510 et P.513.P.510 et P.513.\tStukely.Stukely.\t6.5.\t\t\t\t Commission scolaire catholique de Waterloo \u2014 Catholic school commission of Waterloo\t\t\t\t\t\t\t \t623.P.647, 548.P.1006.\tSheflord.Waterloo.Waterloo.\t\t\tS 388.36 136.79 29.71\t\t$ 388.35 136.79 29.71 \t\t\t\t\t\t\t 152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 104' année, n' S Canton de Stukely-Sud \u2014 Township of South-Stukely Noms Names\tLots\tCanton Township\tRg-rue Rge-6t.\tTaxes Munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal Choquette, Arthur.Robert, Albert.\tP.126-2, P.126-3.P.233.P.411,412.P.341, P.342, P.347 132-58, 132-31.P.212.P.360-55-J-5 est, P.360-56.360-57.P.132.\tStukely.Stukely.Stukely.Stukely.Stukely.Stukely.Stukely.Stukely.\t1.2.5.4.1.3.4.1.\tS 21.63 79.05 25.80 672.23 25.80 69.50 9.27\t3 30.15 104.02 147.96\t\tt 30.15 21.63 79.05 25.80 572.23 25.80 173.52 157.23 Municipalité de Béthanie \u2014 Municipality of Bethany\t\t\t\t\t\t\t Daudelin, Succession.\t791.\tEly.\t9.\tS 2.60 147.44\tf 28.19 215.59 21.98 84.59\t\t3 30.79 147.44 215.59 21.98 84.59 Tétreault, Renald.\t828, 829,830.\tEly.\t10____\t\t\t\t Côté, Réal.\t870, 804, 806.872.\tEly.Ely.\t\t\t\t\t \t180, 181.\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Ville de Waterloo \u2014 Corporation of Waterloo\t\t\t\t\t\t\t Darrah, Mrs Arthur (Gladys) Re : Gertrude Stone Whitehead.\t954.\tWaterloo.\t\t3 23.83\t\t\t3 23.83 Commission Bcolaire protestante de St-François de Richmond \u2014 St-Francis Protestant School Board of Richmond\t\t\t\t\t\t\t \t6,7,9.113.114, 116, 118, 119.\tRacine.\t1.\t\t$ 950.74\t\t$ 950.74 \t\tEly.\t2.\t\t\t\t Village de Stukely-Sud \u2014 Village of South-Stukely\t\t\t\t\t\t\t Hôtel South Stukely.\tP.37.\tStukely.\t\tS 152.63\t3 778.58\t\t3 931.21 St-Valérien de Milton \u2014 St-Valerien de Milton\t\t\t\t\t\t\t Dusablon, Jean.\t396, 529.\tMilton.\t10\t3 17.48\tS 128.59\t\tS 146.07 \t\t\t\t\t\t\t Canton de Granby \u2014 Township of Granby .\t\t\t\t\t\t\t Bédard, Jean-Jacques.Bellefleur.Robert.Bérard, René.Berger Sal & Hall & Al Isidore Schactman & Al.Betco Construction Ltée.Boisclair, Pierre.Bourassa, Mile Marguerite.Caron,.Georges.« .\t869-17.875-13, 875-14, 875-15.497-165.497-154____ 487-16, P.487-17.P.706, B-1.869-20 .P.819.741-22, 740-1.P.546.16-9.P.564, P.666.-P.759.,.\u201e ~.\tGranby.Granby.Granby.Granby.Granby.-.\t\tS 1.31 1.92 47.93 33.80 34.49 1.31 3.26 98.21 21.63 3.13 44.10 .1.68\t$ 8.18 12.80 211.91 134.07 135.58 8.18 425.25 196.98\t\t$ 9.49 14.72 259.84 167.87 170.07 9.49 3.25 523.46 21.63 3.13 241.08 1.68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.10k, No.2 153 Canton de Granby (tuile) \u2014 Township of Granby (continued) Noms Na Lots Canton Township Rg-rue Rge-St.Taxes Munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs Casavant, Roger.Chaput, Jean-Paul.Charbonneau, Roch (Rene Paquin).Chaussé.Jean-Claude.Cloutier-Gosselin.Françoise G Coderre.Gaétan.Corp.d'hyp.& Imm.Shefford Côté Léo, F /Shefford Chesterfield.Courtemanche, Dame Rogor.Courville, Jean-Pierre.Couture, Dame Yvette.Danis, Jean-Guy.Dion, Denis.Duhamel, Bernard.Dumont, Rolland.Dupont, Rosaire.Forand, Gilles.Gagné, Dame Roméo.Gaudreau, Raymond.Gigucre, Roland 4 Lacroix.Gilles.Godin, Marius.Gosselin-Lagacé.Dame Suzanne (J.C.Poulin).Gossclin, Renaud.Gravel, Mlle Micheline.Guay, Robert.Huard, Patrice / Auclair, Jean-Paul.Jutras, Jean-Marc.Labrecque, Gérard.Lajeunesse, Guy.Langlois, Justinien.Lapointe, Joachim.Laverdière, Guy.Lebcl, Roch.Leclerc, Conrad.Lemieux, Gérard J.Les Placements G estoc Inc\u2014 Lussier, Marcel.MuiUoux, Marcel.Major, Marcel.Marquis, David.Marquis, Gérald.Mayrleitner.Martin.Métivier, Roland & Desroches, R.Morand, Jean.Norris, Gordon.Parenteau, Bernard.Poulin, Fernand.Proulx, Arthur.Racine, Rolland.Rodrigue-Inrel.Dame Irène.Savaria, Roger.Séguin, Maurice & Picard, Reynald.Simard, Jacques.Sirois, Raymond.Skinner, Robert.P.17.863-7.P.239.796-40.P.759- 'A sud, P.759-J4 nord.236-4.P.766, 757, 758.P.739.802-11, 802-42____ 802-106.769-28.P.19.878.P.791.802-108, 802-109.P.19-A-9.P.18.352-1.802-150.750, 751.16-18.P.423.P.877.P.827.497-203.497-264, 497-267.497-268, 497-269.P.19-F-A4.P.739, P.739.P.739 P.623.737-10,737-11.788.P.11-A.P.11-B.P.12-A.802-121.P.867.796-39.595-3, 595-4-1, 695-11, 595-12, 695-22, 595-32, 695-33, 595-34.695-35.P.595.450.802-87.P.466.P.835.802-81.802-91.P.219, 220.221, 307 793-21.793-22, 793-23.P.741, P.818.819.849, 853, 866.802-137.P.523.799-4, 799-3-H est.P.864.223-9.P.313-4-3.P.760.421-21.645-1, 645-7.P.423.Ste-Cécile Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Ste-Cécile Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby.Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby Granby 10.10.10.7.36 3.29 40.19 68.83 2.98 13.54 4.74 197.65 4.66 30.80 20.22 2.12 0.04 53.44 34.32 4.88 62.01 48.53 62.55 6.07 21.49 1.44 3,50 83.84 7.10 4.58 98.59 67.39 39.39 11.37 7.30 30.54 1.82 2.88 307.14 2.39 31.69 5.42 34.83 54.92 63.97 13.36 11.68 6.68 19.18 31.85 42.38 21.39 10.38 4.64 6.14 150.17 39.99 74.75 0.42 8 251.12 91.89 1.846.09 26.95 109.26 14.05 1.94 245.75 121.40 26.01 21.88 139.01 107.02 5.88 251.81 23.17 231.22 78.76 28.54 109.66 8.89 112.76 79.66 62.40 58.87 13.66 372.31 58.67 32.73 116.78 137.10 154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 101' année, n° 2 Canton de Granby (tuile) \u2014 Township of Granby (continued) \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Noms\t\tCanton\tRg-rue\tMunie.\tscol.\tFrais\t \tLots\t\t\t\t\t\tTotal Names\t\tTownship\tRge-St.\tMunie.\tSchool\tCosts\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t\t St-Louis, Julien.\t487-53, 487-54.\t\t\tS 32.71 58.14 30.45 1.31 47.32 28.32\tt 120.81 84.49 107.19 8.18 208.50\t\tS 153.52 142.63 137.64 9.49 255.82 28.32 Southière, Patrick.\tP.546, P.835.\t\t\t\t\t\t Tremblay, Jean-Paul.\t869-3-1, 869-2-1.\t\t\t\t\t\t \t869-13.\t\t\t\t\t\t \t793-30, 793-29.\t\t\t\t\t\t \t215, 299.\tGranby.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire catholique de Granby \u2014 Catholic School Commission of Granby Ares, Jacques.\t739-4.\tGranby.\t\t\t\ts\t299\t38\t\tS 299\t38 Carrier, Paul-André.\t337-1 .\tGranby.\t\t\t\t\t202\t17\t\t202\t17 Côté-Racicot, Mme Nicole.\t539-Q.\u2014\tGranby.\t\t\t\t\t139\t53\t\t139\t63 98 \t523-G.\tGranby.\t\t\t\t\t111\t98\t\t111\t \t864-B.\t\t\t\t\t\t305\t07\t\t305\t07 \t802-153.\t\t\t\t\t\t165 6\t24\t\t165\t24 \t660-48\t\t\t\t\t\t\t75 88\t\t6\t76 \tP.14-B .\tSte-Cécile.\t\tS 19\t27\t\t152\t\t\t172\t15 Lemoyne, Armand.\t12-K-R.\tGranby.\t\t\t\t\t124\t33\t\t124\t33 Préfontaine, Albert.\t17A-72, 17-a-73.\tSte-Cécile.\t\t5\t34\t\t96\t39\t\t101\t73 \t17-A-74.17-A-95,\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t17-A-96, 17-A-97.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t17-A-98.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tP.1-A.\tSte-Pruden-\t\t\t\t\t100\t00\t\t100\t00 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t3-A.\tSte-Pruden-\tlOsh.\t\t\t\t123\t66\t\t123\t66 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tP.4-B.\tSte-Pruden-\t\t134\t!il\t\t688\t62\t\t723\t53 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tl-A-45.\tSte-Pruden-\t\t\t\t\t23\t49\t\t23\t49 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tl-A-46.\tSte-Pruden-\t\t\t\t\tg\t32\t\tg\t32 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t Vallicres, Jean-Guy.\t9-A.9-B.\tSte-Pruden-\tlOsh.\t\t\t\t176\t98\t\t176\t98 \t\ttienne.\t\t\t\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Joachim de Shefford \u2014 Municipality of St-.Ioachim of Shefford Delage, Raymond.Cleary, Mme Edward Bombardier, Richard.Daigle, Robert.12, 13, 14, 15.227, 229, P.264.P.334.230, P.232,233,4,7 Shefford Shefford Shefford Shefford \tt 112.00\tt\t180.00\t3 5\t00 \t148.00\t\t150.00\t5\t00 \t24.00\t\t21.00\t3\t00 10.\t390.00\t\t555.00\t30\t00 297.00 303.00 48.00 975.00 Shefford, le 5 janvier 1972.44004-2-2-o Le secrétaire-trésorier, Bernard Ledoux.Shefford, January 5, 1972.44004-2-2-o Bernard Ledoux, Secretary-Treasurer.Municipalité du Comté de Matane Avis public vous est par les présentes donné par le soussigné Secrétaire-Trésorier du Conseil de Comté de Matane, que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus par enchère publique à Matane, au Palais de Justice, le NEUVIÈME jour de MARS mil neuf cent soixante-douze, à DIX heures, de l'avant-midi, à moins que les taxes, frais et autres charges tels que ci-dessous mentionnés ne soient plus tôt payés: Municipality of the County of Matane Public notice is hereby given by me, undersigned Secretary-Treasurer of the Municipal Council of the Municipality of the County of Matane, that the immoveable properties hereinafter described will be sold by public auction at Matane, in the Court House, at TEN o'clock in the morning, the NINTH day of MARCH nineteen hundred and seventy-two, unless the taxes, costs and other charges due as hereinafter described be paid with costs incurred to wit: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IS, 1972, Vol.101, No.2 155 Municipalité de la paroisse de Métis Beach \u2014 Municipality of the Parish of Métis Beach Nom du propriétaire Name of owner\tNuméro du lot Lot Number\tRang Range\tPar.Canton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tTotal \tP.-364.\t2.\tSt-Octave.\t$ 41.04\t$ 36.97\tS 78.01 Un terrain mesurant cinquante-cinq pieds (550 de front A piece of land measuring fifty-five feet (55') in front by par cent pieds (100') de profondeur, avec bâtisses dessus cons- one hundred feet (100') in depth, with buildings thereon truites.erected.Commission Scolaire de La Métis \u2014 School Commission de La Métis \tP.-63.\t1.\tAss.N.-Dame.St-Octave.\t\t8 40.26 24.27\t\tt 40.26 24.27 \"Richard.Mme Armand.\tP.-165.\t2.\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Octave de Métis \u2014 Municipality of St.Octave de Métis\t\t\t\t\t\t\t \t618-619.\t4.\tSt-Octave.St-Octave.\t$ 156.67 28.74 97.13 23.42 28.38\t\t8 174.30 40.26 72.57 32.20 40.26\tS 330.97 69.00 169.70 55.62 68.64 \t\t4.\t\t\t\t\t Roy, Raymond .\t638-639.\t4.\tSt-Octave.\t\t\t\t \t709-710.\t5.fi\tSt-Octave.< 1 ( 1 i ¦ ! ¦ i \\ - .1\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Ulric Village \u2014 Municipality of St.Ulric Village Blier, Réal.\t16-17.\t2.\tSt-Ulric.\tS 84.00 24.00\t$ 157.98 25.94 100.36\tS 241.98 49.94 100.36 \t16-19.\t2.\tSt-Ulric.\t\t\t Michaud, Viateur.\t17-48.\t2.\tSt-Ulric.\t\t\t \t\t\t\t\t\t \" Commission Scolaire de Matane \u2014 School Commission of Matane\t\t\t\t\t\t Bernier, Joseph.\tP.202.\t1.\t\t\t3 145.46\t3 145.46 \t\t\t\t\t\t Municipalité de Petite Matane \u2014 Municipality of Petite Matane\t\t\t\t\t\t \tP.45.\t1.\tSt-Jérôme.\t3 4.35 1.50\t3 13.78\tS 18.13 1.60 Michaud, Edgar.\tP.477.\t3.\tSt-Jérôme.\t\t\t \t\t\t\t\t\t Municipalité de Ste-Paule \u2014 Municipality of Ste.Paule\t\t\t\t\t\t \tP.37.\t12.\tMatane.\t8 62.11\t\t8 52.11 (One house).\t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Luc \u2014 Municipality of St.Luc\t\t\t\t\t\t \t3.\t4.\tTessier.\t3 11.60\t8 6.79\t8 18.39 \t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Adelme \u2014 Municipality of St.Adelme Bouchard, Antoine.Gagné, Roland.Marquis, Marius.Imbault, Philippe.Moreau, Gérard.P.379.P.379.P.379.P.38.33.Ste-Félicité.Ste-Félicité Ste-Félicité.St-Denis.St-Denis.S 268.18\t3 84.46 133.40\t 97.89\t91.64 126.64\t68.35 97.91\t34.26 8 352.63 133.40 189.53 184.99 132.17 156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10k' année, n\" 2 Municipalité de St-Adelme (suite \u2014 Municipality of St.Adeline (continued) Nom du propriétaire\tNuméro du lot\tRang\tPar.Canton\tTaxes munie.\tTaxes scol.\tTotal Name of owner\tLot Number\tRange\tTownship\tMunie, taxes\tSchool taxes\t \t31.\t8.\t\t8 105.04\tS 34.26\t3 139.30 \t39.\t8.\tSt-Denis .\t196.86\t34.25\t231.11 \t388-89.\t4 et 6____ 9.\tSte-Félicité\t78.17\t184.48\t262.65 St-Pierre, Mme Paul.\t46.\t\tSt-Denis.\t149.84\t248.00\t397.86 Boulay, Adrien.\t48-49.\t9.\t\t430.48\t269.92\t702.40 \t\t\t\t\t\t Municipalité de St-Jean de Cherbourg \u2014 Municipality of St.Jean de Cherbourg \tP.17.\t8.\tCherbourg.\tS 26.60\tS 20.22\tS\t46.82 \tP.17.\t8.\tCherbourg.Cherbourg.\t14.11\t9.10\t\t23.21 \tP.17.\t8.\t\t54.35\t64.08\t\t118.43 \tP.15.\t8.\tCherbourg.\t48.79\t35.67\t\t84.46 \tP.17.\t8.\t\t62.96\t66.89\t\t120.85 \t\t\t\t\t\t\t Municipalité de Les Méchins \u2014 Municipality of Les Méchins Banville, Louis.Bouchard, Sylvain.Biais, Georges-Henri.Courcy, Roland.Fournier, Léon.Isabel, Mme Rose-Aima.Gagnon, Jean.Gendron, Paul-Eugène.Lavoie, Mme Joseph.Leclerc, Mme Pierre-Paul Lefrançois, Lucien.Lefrançois, Jacques.Levesque, Vincent.Marceau, Léonard.Parent, Guy.St-Laurent, Lumina.Tremblay, Mme Ovide.Tremblay, Wilfrid.Verreault, Louis-Charles.Verreault, Valère.Verreault, Roger.15-A-l, et 42, 43 22-A-5.P.22-B.P.35-B.P.18-B-15.P.8-1.15-A-2.P.19-A-2.39.4.P.26-B-ll.P.26-B-10.P.25-B-l.19-A-4.18-B-5.29-3.23-A-4.40.P.25-A-3.P.24-A-14.17.let 3.1.1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2.Dalibaire.\t3 112\t75\t8 292\t63\t8 405\t38 \t60\t25\t123\t65\t183\t90 Dalibaire.\t63\t25\t186\t25\t249\t50 Dalibaire.\t20\t25\t\t\t20\t25 \t61\t25\t141\t75\t203\t(II) \t67\t75\t168\t84\t236\t59 \t7\t75\t17\t50\t25\t25 Dalibaire.\t48\t25\t236\t56\t284\t81 Dalibaire.\t12\t00\t45\t93\t57\t93 \t8\t50\t51\t16\t59\t66 \t81\t25\t240\t00\t321\t25 \t51\t25\t\t\t51\t26 Dalibaire.\t57\t15\t153\t35\t210\t60 Dalibaire.\t42\t75\t139\t50\t182\t25 Dalibaire.\t72\t25\t209\t50\t281\t75 Dalibaire.\t80\t36\t105\t12\t185\t48 Dalibaire.\t101\t75\t372\t94\t474\t69 \t5\t50\t8\t75\t14\t25 Dalibaire.\t108\t25\t\t\t108\t25 \t139\t25\t363\t50\t502\t76 \t5\t50\t13\t13\t18\t63 Matane, 5 janvier 1972.43989-2-2-o Le secrétaire-trésorier, Robert Otis.Matane, January 5th, 1972.43989-2-2-0 Robert Otis, Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de St-Hyacinthe Avis public est, par les présentes, donné par le soussigné .{.-Jacques Giasson, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de St-Hyacinthe, que les immeubles suivants ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, à la salle du conseil au Palais de Justice, en la cité de St-Hyacinthe, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont assujettis et des frais encourus, à savoir: Municipality of the county of St-Hyacinthe Public notice is hereby given by the undersigned J.-Jacques Giasson, Secretary-Treasurer of the corporation of the county of St-Hyacinthe, that the following immoveables hereinafter mentionned shall be at public auction, in the hall of the county council, at the Court House, in the city of St-Hyacinthe, on THURSDAY the NINTH day of MARCH, 1972 at TEN o'clock in the forenoon, in default of payment of the taxes for which they are liable, and the costs incurred, namely to wit: QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 157 Municipalité de la paroisse de St-Denis sur Richelieu \u2014 Municipality of the parish of St-Denis sur Richelieu Propriétaire Owner Taxes Taxes Int.et No du cadastre\tmunie.\tscol.\tfrais\t \t\t\t\tTotal No.of cadastre\tMunie.\tSchool\tInt.and\t \tTaxes\tTaxes\tcosts\t P.424.\t$ 72.25\t\t\t$ 72.25 P.21-22.\t82.94\t\t\t82.94 P.36.\t175.16\t3 368.70\t$ 32.35\t566.21 (5-20), (5-21).\t17.36\t\t\t17.36 P.232, P.231.\t50.97\t\t\t50.97 P.231.\t\t12.47\t1.80\t14.27 P.231, P.231, P.231.\t\t295.80\t27.29\t323.09 P.231, P.232, P.232-1.\t\t134.69\t11.92\t146.51 P.31.\t\t6.62\t1.66\t8.27 265-5.P.265, 265-4,\t\t121.30\t9.98\t131.28 P.265.\t\t\t\t P.231, 164-178, 166-3,\t\t104.16\t4.35\t108.50 Gariépy, Rosaire.St-Denis sur Richelieu.Laganière, Fernand.St-Denis sur Richelieu.Thivierge.Mme Gertrude Bertrand, St-Denis sur Richelieu.St-Laurent.Donat, Lac Renaud.St-Jovite.Gaudette, Jean-Paul, 161 rue Roy, Dorval.Gaudette, Jean-Paul, 161 rue Roy, Dorval.Gaudette, Jean-Paul, 161 rue Roy, Dorval.Gaudette.Jean-Paul.161 rue Roy.Dorval.Bergeron, Lucien, 4405 Beaubien est, Montréal.DesluUriers, Henri, a/s Georges Laçasse, 6987 Hve.Guy.Montréal 435.Ouellette.Albert.St-Denis sur Richelieu, comté de St-Hyacinthe.166-2.Municipalité du village de St-Denis sur Richelieu \u2014 Municipality of village of St-Denis sur Richelieu Gaudette, Jean-Paul, 161 rue Roy, Dorval.Ouellette, Albert.St-Denis sur Richelieu, comté de St-Hyaciuthe.P.231,.3 278.31 164-178, P.231, 166-2-3.404.02 S 278.31 404.02 Municipalité de la paroisse de St-Charles sur Richelieu \u2014 Municipality of the parish of St-Charles sur Richelieu Blanchard.Michel ou Bertrand, R.R.1, Marieville, comté de Rouville, Québec.Gagné, Georges A., 97 Ruisseau Nord, Beloeil.Lefèvre, P.-Emile, 2444 Knox, Pte Ste-Charles, Montréal.315, 315-A.S 1.20 P.241.P.128-129.85.93 $ 16.37 8 103.50 31.97 8.53 40.50 256.03 25.97 282.00 Municipalité du village de Ste-Madeleine \u2014 Municipality of village of Ste-Madeleine Succ.Louis Gaudreau, La Curatelle Publique, 9310 Boul.St-Laurent, Montréal 354.Girouard, Orner, La Présentation, Cté St-Hyacinthe.Jodoin, Achille, Ste-Madeleine.39-3.\t.3 158.80\t$ 16\t87 S\t175\t67 153*2.\t.90.35\t6\t.55\t96\t90 137-12.\t.28.50\t2\t63\t31\t13 43-25.\t.102.60\t11\t48\t114\t08 \t\t25\t18\t212\t68 43-12.\t41.80\t3\t47\t45\t27 Municipalité de la paroisse de La Présentation \u2014 Municipality of the parish of La Présentation Luc, Georges, La Présentation.P.457.Desmarais.Real, St-Thomas d'Aquin, 472, P.473, P.631-533- Cté St-Hyacinthe.P.534-253-256.Laperle.Ernest, St-Denis sur Richelieu, P.50.Cté St-Hyacinthe.Lavoie, Romuald, adresse inconnue.P.418.717.98 8 1.535.79 364.21 1,813.58 9.36 45.41 43.06 239.87 173.14 S 2,426.91 396.07 6.19 81.63 2,573 S 58.61 366.91 Donné à La Présentation, ce 5e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 43990-2-2-o J.-Jacques Giasson.Given at La Présentation, this 5th day of January, 1972.J.-Jacques Giasson, 43990-2-2-o Secretary-Treasurer. 158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 197S, 10i- année, n° S Municipalité du comté de Vaudrcuil Avis public est par les présentes donné par F.Ed.Belliveau, secrétaire-trésorier, que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus par ancan public, dans la salle des sessions dudit conseil, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS prochain 1972, à DIX heures de Pavant-midi, pour taxes municipales, scolaires et d'église dues aux municipalités ci-après mentionnées, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais avant la vente.Municipality of the County of Vaudreuil Public notice is hereby given by F.Ed.Belliveau, secretary-treasurer, that the immoveable properties hereinafter described shall be sold by public auction in the sitting hall of the said Council on THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal, school and church taxes due to the hereinafter mentioned municipalities unless the same be paid with the costs before the sale.Corporation de la Terrasse Vaudreuil \u2014 Corporation of the Terrasse Vaudreuil Propriétaires Owners\tNos officiels Official Nos.\tCadastre\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tÉglise Church\tTotal Bernier, Jean-Paul.Bourbonnais, J.-Marcel.Brière, Real\t182-502, 180-48.182-503, 180-49.182-504, 180-50.180-51, 182-605.182-180.182-24.\tHe Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.\t$1,056.64 62.95 62.94 62.95 179.40 71.25 48.95\t$ 281.26 21.85 21.85 21.85\tt 16.38 27.09 22.05 17.01 20.79 32.44 21.42 31.18 16.06\t$ 1,336.90 84.80 84.79 84.80 16.38 27.09 22.05 17.01 200.19 103.69 21.42 31.18 16.06 49.95 Clermont, Gerald.Gilbert, Hervé.\t182-168.183-10.\tHe Perrot.\t\t\t\t Lefebvre, Riohard.\t182-177.\tHe Perrot.He Perrot.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Skalak, François.\t182-P.116 & 116.182-P.423.\tHe Perrot.\t\t\t\t Corporation de la paroisse de Ste-Marthe \u2014 Corporation of the parish of St.Marthe\t\t\t\t\t\t Lavallée, Jean-Marc .\t89, 90, 194, moitié est lot 195 403.P.415.\tParoisse Ste-Marthe.P.Ste-Marthe.P.Ste-Marthe.\t$ 62.43 23.54 .63\tS 313.34 363.12 6.37\tS 67.78\tS 443.55 386.66 6.90 Corporation de Ste-Justice de Newton \u2014 Corporation of St.Justine de Newton\t\t\t\t\t\t \tP.174.\t\t$ 45.39\tS 146.30\tDivers Misc.Ï186.03\tt 378.72 Corporation de la paroisse de Très St-Rédempteur \u2014 Corporation of the parish of Très St-Rédempteur\t\t\t\t\t\t Ferland Courtemanche,.Jacqueline Mongeau, Azellus.Fiorito, Antoine.Lavallée, J.-M.et.Lefebvre, Gaston\tP.77.P.67, P.68.P.67, P.68.P.76.P.76.\tP.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.\tt 66.77 3.88 36.32 3.22\t* 111.14 18.76 161.93 39.32 682.26 60.67 24.97\t\t$ 1 76.19 22.64 197.25 39.32 582.26 53.79 24.97 Renaud, J.-Hector.\tP.67.P.76.,.\tP.St-Rédempteur.P.St-Rédempteur.\t\t\t\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 1972, Vol.101, No.2 159 Corporation de Vaudreuil sur le Lac \u2014 Corporation of Vaudreuil sur le Lac Propriétaires Owners\tNos officiels Officiai Nos.\tCadastre\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes 8COl.School taxes\tÉglise Church\tTotal Club Nautique Deux.Montagnes Inc.Belle-Plage Development Corporation\tP.1783.P.1785.P.1782.P.1784 P.1781.P.1782.\tSt-Michel de Vaud.St-Michel de Vaud.St-Michel de Vaud.\t\t$6,064.10 2.252.93 1,869.20\t\t$ 6,064.10 2,262.93 1,869.20 Corporation de la paroisse de St-Lazare \u2014 Corporation of the parish of St.Lazare Bierbrier, Mrs.H.Ghevrier, Joseph.Geertsen, Georges.Mergl, Succ.Frank.Paiement, L.R.Parr, Miss A.Marguerite Pilon, Eric.Veitleux, Victorin.Largo Construction Inc.La Société d'Aqueduc de St-Lazare La Société d'Aqueduc de St-Lazare Vel-Con of America.P.188.P.14.P.518.P.167.P.568.P.168.360 P.2-361-24 P.360 P.2-361 P.24 P.25-P.29.P.482 \u2014.483.P.479.P.166.Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare Par.St-Lazare.Par.St-Lazare Par.St-Lazare 2.22.5 17 11 37.6.104.69 350.30 47.14 227.53 58.51 80.13 328.23 42.76 931.82 3.24 708.04 100.72 Corporation de Pointe-Fortune \u2014 Corporation of Pointe-Fortune Campeau, Dame.Germaine Constantakis, Georges.Katinakis Triandafmos.Steckler, Henry.- St-Jean, Mme Rosario.Houston Garth et al.P.83.P.18A.P.18A, 18A-18, 19, 20,.31 à 36, 40, 41 P.18A.P.18A.Pointe-Fortune.Pointe-Fortune.Pointe-Fortune.Pointe-Fortune.Pointe-J*\" ortu ne.$ 28.38 2.00 85.00 22.13 8 146.63 48.54 959.70 118.56 108.48 Corporation de la paroisse de Rigaud \u2014 Corporation of the parish of Rigaud Aubin, Dame Denise.Bassot, Jean-Noël.Beaven, Marc.Bédard, Dame Leda- Bédard, Dame Leda.Béland, Claude M.Boissonneault, Mme F.Chevrier, Guy & Antonio Pelletier Chevrier, Guy & Antonio Pelletier Cappelo, Mario-Rodrigue Charlebois, J.-Pierre.Blanchette, J.-P.Courtemanche, Jean-.Louis et al De Laurentis.Arimondo.Derrick, Donald.Deschesnes, Claude.Dubois, Gilles.Dubois, Gilles.Dufour, Ernest.Johnson, Gérard.P.542.P.152.P.190.517-5.P.517.P.526.36-63.P.30.36-20, 21, 22.26.27.28, 31 à 44, 47 à 55, 58, 66 à 69,' 36-246 à 259, 362, 363.P.366, 461 P.607.P.6.P.517.P.141.546-40.36-P.366.P.617.P.562- P.563- 36-469.617-32.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.49.95 68.65 143.35 199.65 8.25 6.70 27.95 9.10 1 191.79 30.66 22.18 106.97 31.78 305.64 77.44 663.73 1,018.10 68.38 32.78 188.39 22.18 10.37 81.74 88.01 32.78 285.95 160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Corporation de la paroisse de Rigaud (suite) \u2014 Corporation of the parish of Rigaud (continued) Propriétaires Owners Nos officiels Official Nos.Cadastre Taxes munie.Munie.taxes Taxes scol.School taxes Église Church Fortier.Jean.Froment, Pierre.Froment, Mme Yvette .Remue, Roger.Faubert, Marcel.Faubert, Marcel.Gauthier, Hororius.Gaulin, Robert.Giraldeau, Willie.Giroux, Normand.Giroux, Normand.Gourdes, Bertrand.Hamelin, Dame France.Hayes, Jean.Henderson, Dame.Gilberte Henderson, Dame.Gilberte Joly, J.-Guy.Lalonde, J.-Paul.Larose, J.-Guy.Lauzon, Lorenzo.Lavoie, Raymond.Leclaire, Dame.Eugénie Létourneau, J.-A.Proulx, René.Mallette, Bernard.Martel.Théodule.Provost.Louis.Massia.Damasse.Ouellette.Amédé.Quesnel.Vvon.Rebts, Gaston.Rioux, Colette.Berlinguette, Gérard Ritchie, William.Russ, John R.St-Jean, Léo.Seguin, Marcel.Sévigny, Réal.Bond, Benoit.Tinsley, Richard et al.Trépanier, Aurèle.Trépanier, Mme Aurèle.Venor, Robert & Cohen Joseph Venor, Robert & Cohen Joseph Jolly Realty Co.Inc.et al Jolly Realty Co.Inc.et al Rozon, Bruno Succ.P.1, 1-14, 15, 16, 19.P.529.P.525.546-48.546-32.\".540-31.P.36-75.P.108.1\".169.36-433.S.____ 36-432.P.580.36-81, 36-02.P.227.P.21.P.526.P.183.P.517.P.580.P.169.P.2.36-480.P.36-75.P.29.P.103.P.142.2-14.P.30.513-16.36-P.485.P.169.P.190.P.146.P.97.P.580.P.548.517-30.546-78.P.219, P.158.66-P.30, 66-31.P.4.110.P.105.178.^.179.P.120.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud^ Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.Par.Rigaud.3.40 43.75 36.40 10.20 81.04 39.60 12.15 3.40 45.50 73.75 117.49 12.25 12.70 14.16 60.45 51.62 40.10 474.62 411.74 105.23 21.18 43.98 43.98 265.97 181.25 21.18 223.59 43.40 293.07 32.78 158.95 43.40 61.81 32.79 465.52 66.99 159.95 424.44 396.79 32.78 48.48 299.98 257.26 375.04 66.99 43.40 106.97 66.99 3211.M, 164.21 85.80 112.98 88.18 197.94 108.85 128.50 52.63 308.97 307.98 199.49 Corporation de N.-D.de l'Ile Perrot \u2014 Corporation of N.-D.de l'Ile Perrot Carrière, Jean-Claude.Rheted Investments Ltd The Wister Corporation Dame Rose Wisenthal Weiner Elru Investments Ltd.Roskies.H.et al.Olshansky, Issie et al.D'Ambrosio, Val.61-19-1.P.107____ 83, 86, 87 P.102.P.105, P.106,.P.108 P.102.P.105, P.106,.P.108 P.107.He Perrot.He Perrot.He Perrot He Perrot He Perrot I 211.49 156.00 310.66 116.37 24.74 8 113.45 170.27 410.02 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 161 Corporation de N.-D.de l'Ile Perrot (suite) \u2014 Corporation of N.-D.de l'Ile Perrot (continued) Propriétaires Owners Nos officiels Official Nos.Cadastre \tTaxes\tTaxes\tÉglise\t \tmunie.\tscol.\t\t \t\t\t\tTotal \tMunie.\tSchool\tChurch\t \ttaxes\ttaxes\t\t \t$ 597.21\t$4,469.42\t\t$ 5,066.63 \t519.58\t199.67\t\t719.25 \t746.10\t2,133.49\t\t2,879.59 \t26.33\t\t\t26.33 \t523.57\t\t\t523.57 \t513.48\t7,543.20\t\t8,056.68 \t95.97\t\t\t95.97 \t80.00\t84.55\t\t164.55 \t136.94\t\t\t136.94 \t113.10\t99.84\t\t212.94 \t3.27\t\t\t3.27 \t123.23\t\t\t123.23 \t145.81\t121.00\t\t266.81 \t58.41\t\t\t58.41 \t65.89\t638.99\t\t704.88 Bavin Investments Ltd Window Holdings Ltd.Forward Holdings Ltd.Lalonde, Roland.Berkeley Holdings Ltd.Amini, Samuel.The Directors', the.Veterans' Land Act Druker, Samuel.Arant, Reynold.Houle, Mme Lucie.Gravel, Henri.Barrette A.Succ.Martin.Michel.Marchand, John.Perron, Gérard.P.253.P.254.P.313 P.255, P.313 P.258.P.282, P.294.P.281, P.280.P.276.268-117, 118.268-105.268-94.288-41.P.267.266-11.266-52.P.265, 265-16 He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.Ile Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.He Perrot.Donné à Vaudreuil, ce 6e jour de janvier 1972.Copie conforme.Le secrétaire-trésorier, 44005-2-2-o F.Ed.Beluveau.Municipalité du comté de Soulanges Avis public est, par les présentes donné que les terrains ci-après mentionnés seront vendus seion les dispositions du Code Municipal, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi pour taxes scolaires, municipales et autres redevances dues aux municipalités ci-après mentionnées, à moins qu'elles ne soient payées avec les frais avant la vente, à savoir: Given at Vaudreuil, this 6th day of January 1972.True Copy.F.Ed.Beluveau, 44005-2-2-o Secretary-Treasurer.Municipality of the County of Soulanges Public notice is hereby given that the lands hereinafter mentioned will be sold according to the provisions of the Municipal Code, on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for school and Municipal taxes, and others debts due to the municipalities mentioned below unless they are paid with the costs, before the sale, to wit: \tLa commission scolaire de Soulanges \u2014 School Commission\t\tof Soulanges\t\t Noms\tNuméro du cadastre\tTaxes scolaires\tTaxes munie.\tRépart.d'Eglise\tTotal Names\tCadastral number\tSchool taxes\tMunie, taxes\tChurch repart.\t Saint-Télesphore\t\t\t\t\t Mrs.Nelson Davis.\t.P-325.\t$ 79.21\t$ 13.75\t\t8 92.96 Saint-Polycarpe\t\t\t\t\t Hervé Major.\t.P-475-6.\tS 194.20\t$ 14.17\t\t8 208.37 Ste-Claire d'Assise \u2014 Riviere Beaudette\t\t\t\t\t Jean-Marie Delangis.793-46.RéalFerland.493-74.Ronald Samuel Juver.P-884.J.Boyd & H.McDonald.P-881.Léonard Pilon.793-29.Xiste Ravary.P-887.118.66 221.65 33.81 199.92 166.02 33.82 118.56 221.56 33.81 199.92 166.02 33.82 102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1973, MA' année, n\" 2 Village de Saint-Zotique Noms Names Numéro du cadastre Cadastral number Taxes scolaires School taxes Taxes munie.Munie, taxes Répart.d'Eglise Church repart.Total Hector Daoust.P-682____ Steven Demers.769-5- Guy Lamontagne.769-96.Maurice Lemieux.769-43-44.Sébastino Marganti.P-767____ Marie J.D.Perron.767-4____ Dame Yvette Pinsonneault.10-62.Raphaël Stromei.26-184.Roland Villeneuve.P-773.Arthur & Rolland Villeneuve.P-773____ 107.11 31.78 61.24 241.97 42.56 213.40 251.53 17.48 94.74 69.22 2.80 5.81 30.40 262.09 4.43 23.22 11.05 2.03 12.73 107.11 34.58 61.24 253.02 50.40 243.80 526.35 21.91 117.96 69.22 Village de la Station du Coteau Jean-Guy Deguire.P-166.Mme N.W.Jourdenais.P-143.245.04 133.76 159.08 50.45 404.12 184.21 Paroisse de Saint-Ignace du Coteau du Lac \u2014 Parish of Saint-Ignace du Coteau du Lac Fondation pour la Culture et l'Éducation.P-10-P-11.$4,087.11 $4,087.11 Corporation municipale de la paroisse de Sainte-Claire d'Assise Municipal corporation of the parish of Sainte-Claire d'Assise Fernand Dubé.P-S89.Dame James Dawson.P-885.H.J.O'Connell.861-862.H.J.O'Connell.881-882.Jean-Paul Touchette.P-884.$ 259.95 160.03 560.98 441.35 42.28 28.80 21.59 87.88 89.47 302.23 28.80 181.62 648.86 530.82 La Fabrique de la paroisse de Saint-Zotique \u2014 The Fabric of the parish of Saint-Zotique Gilles CouUlard.Alain L'Heureux.Dame Jacques Hébert née Monique Sauvé.René Loiselle et Dame Irène Lefebvre.Dame Georges Picinbono, née E.Caudine Brevin.Denis St-Pierre.Ken Hall.Rock Trépanier.Dame Huguette Isabelle Cadieux.Adrien Pothier.André Marleau.Jacques Hébert.Armand Latour.Emilio St-Michel.Dame Rita Amyot, L.Z.Vincent.J.Denis Leduc.Albert Laitre.Dame Estelle St-Denis.10-5.$ 220.20 P-19.75.64 57-19-20-21-22-23-24, 67-P-18.57-P-25.340.48 660.571.68 683-1.1,092.29 P-684.P-744.21.65 767-6.139.60 767-12-44-45 .519.12 776-96 .292.25 767-109.768-P-16, 768-17-35.86.42 768-80,768-100 .83.62 770-3.104.60 P-776.41.68 695-14 .39.12 767-198,768-139 .39.12 P-773.77.35 211.28 88.83 656.27 1,457.83 1,275.52 21.42 6.65 37.38 118.62 77,67 10.05 74.35 6.64 3.40 5.83 7.66 $ 23.76 33.74 148.11 64.25 132.92 10.18 6.70 15.86 52.53 50.39 4.69 38.62 24.81 15.23 6.70 6.20 5.20 7.42 455.24 198.21 1,144.86 2,093.76 2,500.73 31.60 35.00 192.84 690.27 420.31 14.74 124.04 108.33 194.08 64.92 47.72 60.16 92.33 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10k, No.2 163 La municipalité de la paroisse de Saint-Ignace de Coteau du Lac The municipality of the parish of Saint-f gnace de Coteau du Lac Noma Names Taxes Taxes Répart.Numéro du cadastre\tscolaires\tmunie.\td'Eglise Cadastral number\tSchool\tMunie.\tChurch \ttaxes\ttaxes\trepart.P.375.\tS 194.23\tS 20.50\t P-234.\t39.19\t20.98\t P-16.\u2022.\t87.30\t20.89\t 149-9.\t134.39\t24.21\t 157-1,233-1.\t2,119.73\t139.93\t P-16, P-16, P-21, P-24.\t\t2.13\t 122-75-76.\t\t3.14\t 122-191-192.\t17.71\t3.14\t P-409, 122-186-187.122-188-189.\t384.78\t25.50\t Total Almanzor Audette.René Besner & René Levac.Germain Carignan.Léonide Chiasson.Venise Motel Inc.Dame Marguerite Sinray.Jean Valiquette.Martial Ménard.Léon Ménard.S 214.73 60.17 108.19 158.60 2,259.66 2.13 3.14 20.85 410.28 \tLa corporation municipale du Village de Coteau du Lac\t \tThe municipal corporation of Village de Coteau du Lac\t Léo Charlebois.\t.120-28, 120-29-30.S 447.97 S 272.25\t?720.22 La commission scolaire de Vaudreuil \u2014 The school commission of Vaudreuil\t\t s 171.e Michel Asselin.P-344.Michel Asselin.P-344.Carmen Binette.P-308.Mlle Françoise Brisebois.P-128.Valentino D'Ambrosio.P-263.Valentino D'Ambrosio.83-P-84.Valentino DJAmbrosio.57.Hector Daoust.116.Georges Lambert.U-342-5, H-342-6, U-342-7, 14-342-8, H-342-9, H-342-10, K-342-10, H-342-11, H-342-12, J4-342-13, H-342-14, J4-342-15, U-342-16, U-342-17, H-342-18, K-342-19.K-342-24, ^-342-25, H-342-28, H-342-29, M-342-30, M-342-31, H-342-32, H-342-33, H-342-34, U-342-35.M-342-36, H-342-37, H-342-38, J4-342-39, Î4-342-40, J^-342-41, H-342-42, H-342-43, H-342-44, U-342-45, U-342-46, H-342-47, K-342-48, U-342-49, H-342-50, H-342-51, i-i-342-52, M-342-53, H-342-54, H-344-5, H-344-6, lz-344-7, 14-344-8.U-344-9.W-344-10.U-344-11.H-344-12, H-344-13.M-344-14, H-344-17.H-344-21.H-344-26.H-344-29 K-344-30, !^-344-31, U-344-32.K-344-33.H-344-34, H-344-35, )^-344-37, H-344-38, H-344-39, H-344-40.H-344-41.K-344-42 J4-344-43, ^-344-44, ^-344-45, H-344-46, M-344-47, J4-344-48, ^-344-49, J4-344-50, >S-344-51.S 585.74 507.90 918.55 243.98 159.74 1,218.70 474.94 14.88 217.49 49.38 3.33 29.63 t 767.43 607.90 918.55 293.36 159.74 1,218.70 474.94 18.21 247.12 La corporation municipale de la paroisse de Saint-Joseph-de-Soulanges The municipal corporation of the parish of Saint-Joseph-de-Soulanges Michel Deschamps.P-312.\tS 188.99\tS 133.27 143-P-7, 143-11, 143-P-7-5.\t28.96\t16.36 139-13.\t7.71\t4.58 139-4.\t8.39\t4.94 342-22-23.\t72.65\t66.02 130-5.\t77.04\t55.40 130-10-P-17-P-18-P-130.\t74 50\t53.69 140-16.\t\t58.77 P-274, 344.P-322, P-262, P-344,\t\t P-139, 140, 141, 142, 143, 144,\t\t 145, 146.\t3,231.54\t722.20 322.26 46.32 12.29 13.33 138.67 132.44 128.19 68.77 3,953.74 L'énumération abrégée des numéros cadastraux a été autorisée par la Commission municipale de Québec, le 15 décembre 1971.Donné à Coteau Landing, ce 3e jour de janvier 1972.r .(Sceau) ' Le secrétaire-trésorier, 43991-2-2-0 L aubier Léger.The abreviated enumeration of the cadastral numbers has been authorized by the Québec Municipal Commission on December 15, 1971.Given at Coteau Landing, this 3rd day of January, 1972.(Seal) Laurier Léqer, 43991-2-2-0 Secretary-Treasurer. 164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n\" 2 Municipalité du Comté de Montcalm Avis public est par les présentes donné par le Secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Montcalm, que JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS, mil neuf cent soixante-douze, à DIX\" heures de l'avant-midi, en la salle municipale du Comté de Montcalm, à Ste-Julienne, les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus, sujet néanmoins au paiement de ce qui pourrait être dû au Gouvernement Provincial, pour le prix desdits lots, savoir: Municipality of the County of Montcalm Public notice is hereby given by the undersigned Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Montcalm, that on THURSDAY, the NINTH day of MARCH, nineteen hundred and seventy-two, at TEN o'clock, in the forenoon, in the municipal hall of the County of Montcalm, at Ste-Julienne, the following immoveable properties will be sold at public auction in default of payment of taxes for which they are liable, and the costs incurred, subject however to the payment of what could be due to the Provincial Government for the price of said lots, to wit: Corporation municipale du canton de Rawdon \u2014 Municipal Corporation of the Township of Rawdon Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre \t\tTaxes\tTaxes\tFrais et\t Rang\tCanton\tmunie.\tscolaires\tintérêts\t \t\t\t\t\tTotal Range\tTownship\tMunie.\tSchool\tCosts\t \t\ttaxes\ttaxes\tand int.\t 10.\tRawdon-\t8 15.77\t8 14.50\t\t$ 30.27 10.\tRawdon.\t5.83\t3.27\t\t9.10 8\tRawdon-\t64.98\t310.26\t\t375.24 5.\tRawdon____\t37.70\t129.43\t\t167.13 10.\tRawdon____\t6.01\t26.95\t\t32.96 11.\tRawdon.\t7.51\t14.48\t\t21.99 5.\tRawdon.\t15.58\t20.30\t\t35.88 6.\tRawdon.\t27.96\t38.77\t\t66.73 6.\tRawdon.\t34.69\t142.66\t\t177.35 10.\tRawdon.\t\t15.77\t\t15.77 10.\tRawdon.\t5.83\t\t\t5.83 4.\tRawdon.\t12.60\t58.73\t\t71.35 9.\tRawdon-\t248.51\t71.98\t\t320.49 6.\tRawdon.\t14.01\t101.46\t\t115.47 9.\tRawdon-\t9.51\t19.00\t\t28.51 8.\tRawdon____\t29.91\t46.22\t\t76.13 8.\tRawdon____\t27.62\t61.52\t\t89.14 4.\tRawdon.\t55.86\t4.65\t\t60.51 11.\tRawdon.\t16.72\t35.75\t\t52.47 7.\tRawdon.\t\t27.94\t\t27.94 4.o\tRawdon.\t229.60\t298.80\t\t528.40 O.4.\tRawdon-\t169.78\t138.73\t\t308.51 7.\tRawdon-\t14.29\t20.30\t\t34.59 6.\tRawdon.\t10.46\t20.42\t\t30.88 8.\tRawdon.\t12.79\t41.47\t\t54.26 8.\tRawdon.\t8.22\t24.82\t\t33.04 10.\tRawdon-\t6.83\t7.84\t\t13.67 8\tRawdon-\t37.01\t57.25\t\t94.25 11.\tRawdon-\t6.29\t28.24\t\t34.53 6.\tRawdon.\t29.09\t62.23\t\t91.32 8.\tRawdon____\t\t14.56\t\t14.56 11.\tRawdon.\t1.00\t\t\t1.00 7.\tRawdon.\t1.00\t\t\t1.00 9.\tRawdon.\t9.86\t67.23\t\t77.09 11.\tRawdon.\t8.90\t16.87\t\t25.77 6\tRawdon____\t47.65\t68.03\t\t115.68 5\tRawdon.\t11.49\t24.15\t\t35.64 8\tRawdon.\t29.91\t66.68\t\t96.59 5.\tRawdon.\t» 7.39\t36.12\t\t43.51 8 .\tRawdon.\t8.34\t47.45\t\t55.79 10.\tRawdon.\t6.83\t\t\t5.83 10.\tRawdon.\t5.83\t7.84\t\t13.67 10\tRawdon-\t5.83\t10.41\t\t16.24 10\tRawdon-\t32.86\t16.98\t\t49.84 \tRawdon____\t116.09\t\u2022 267 93\t\t384.02 10.\tRawdon.\t60.51\t45.23\t\t105.74 Balfe Ryckart N.Beaulieu Yvon.Brazil John.Brown Robert & Paul.Cardin Leopold.Carmoniso Cosmo.Dayback Mme Ludmilla.Desrosiers J.T.Gabriel.Desroches Hector.Diamond Lucien.Dupuis Henri.Ellson Antony.Gamrat Inc.Guerra Joseph.Jeffrey Henri.Krzisnik Ivo.Ladouceur Robert.Laurentian Hunt & Country Club Lebel.Mme Angéline.Les Developments Rawdon, Les Terres Laurentiennes.Magnan, Claude.Mainville, Hector.Mistioni, Antonio.Mrakic.Anton.Nahorniak.Nicholas.Nelson.Normand.Oatway, Robert.Penta Donato Delli.Picard.Claude.Pontbriand, Mme Henri.Inconnu.Inconnu.Inconnu.Renaud, Raymond.Robidoux, Philippe.Roza , Georges.Sachewski, Alex.Savard.Paul.Stojanovic, Mladem.Batson.Sinclair.Sitcoff.Sam.Soto, Louis.Ladouceur.Francois St-Onge.St-Germain, André.Sigouin, Mme Gilles.P7b.16b-258.P.9c.P.12c.P.16A.P.14b.P.14A.P.7c.P.7c.16b-243.16b-269.P.23A.P.6A.P.7c.P.16A.P.11A.P.16b .P.20A.11-340.P.12c et P.12b.P.20b.22o.P.23A.17c-17.P.7c.P.9c.P.15.16b-214.P.7c.P.14b.8b-84, 85 & 86 .P.13 & P.13b.P.4c.P.22d.1 b.P.10A.6A-52 & 53.P.16A.P.5b.P.21c.P.5b.16H-279.16b-183.16b-306.16b-223.P.4A.P.28c. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 165 Corporation municipale de St-Liguori \u2014 Municipal Corporation of St.Liguori Noms et prénoms Names and surnames\tNuméro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal \t248.\t\tSt- Liguori.St-Liguori.\t$ 1.20 28.78\t$ 4.39 104.79\tS 0.75\t$ 6.34 141.39 Pasatino, Dame Angelo et Gusepte\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford Bérubé, Gaston.Bordeleau, Maurice.Côté, Mme Manon.Doré, Jean-NoBl.Frascadore, Bruno.Hêtu, Roger.Labelle.Mme Jean.Lacombe, Mme Armand.Succ.B.Owens Lobley.Roy, Gravel Régina.Roy, Paul-Emile.Toth.Dme Kalman.(Margit Toth) Williamson, Walter.Akkaoui Claude A Inc.Alarie, Guy.Ares Inc.Ares, Napoléon.Aubé, Guy 4 Uxor.Auberge Grande Vallée Inc Aucoin, Joseph.Barry, Gorden Maogan.Boisvert, Claude.Chartrand, Mlle Dora.Côté, Maurice.Coulombe Adrien.Couture, Martial.Daigneault, Clément.Daigneault.Suzanne 4 Ares Napoléon.Denogens, Jean-Claude.DeVlieger.Patrick.Domaine Gentilly Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine Grande Vallée Inc.Domaine du Lac Michel Inc.Duchesne, Leopold.Duval, Jacques Dct.Frechette, Dme Frank.Funaro, Alfred.Gauthier, Serge.Germain, Dme Rosette.Gluckman.Dme Thérèse (Bardoux).P.41.P.48A.P.57.P.52.P.52.P.57.P.52.42 s 20.P.43.P.44.P.44.P.57.P.42 et P.47b.P.54.53.55 s 1 & 17.P.47A.30A s 5.25 s 10, 11, 12, 13,44 4 45.26 s 1.5, 6, 13, 18, 19, 20, 28.29 4 30 P.10.P.37 & 37 s 221.37 s 107 4 108.P.8b.7A s 13 & 14.39 s 230.19 s 6 et 20 s 2.P.36 4 37.P.29.37 s 95 & 155.38 s 30.81 4 248 39 s 204, 205, 206, 266 & 367.35 s 35, 41, 42 4 46., 36 s 16 et 37 s 222 et 38 s 57 et 58.35 s 76.39 s 393.P.27.55 s 4 et 55 s 5.P.34 ouest.P.38 ouest.36 4 37 ouest.35 ouest et P.38 ouest.25 4 26.P.19 s 9.39 s 285 4 286.P.39.P.35 4 36 et 35 s 2 et 36s 11.P.10.P.9.P.29.'.46b et 47.54 et 55.7.7.7.2.2.7.5.7.4______ Wexford.Wexford.Wexford____ Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.Wexford.\t3 8.40 11.85 14.00 22.40 114.80 119.50 18.60 128.80\t3 13.48 26.15 36.07 67.00 274.33 294.54 28.57 99.60\t3 0.80 3.87 4.30 1.60 19.48 0.80 22.45 3.54 1.60\t$ 22.68 41.87 54.37 91.00 293.81 115.60 436.49 50.71 230.00 Wexford.Wexford.Wexford.\t28.53 80.15 8.00\t23.33 127.05 45.70\t0.80 13.93 3.75\t52.66 221.13 57.45 Wexford.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.\t7.00 16.00 1.40 34.44\t108.56 133.90 135.41\t6.65 0.80 11.22\t115.21 7.00 149.90 2.20 181.07 Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chestsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.\t12.00 449.60 4.76 7.00 0.70 14.00 170.80 92.00 59.92\t34.28 1.354.99 12.28 22.86 39.99 4.00 64.92 262.82 185.34\t2.27 2.10 2.42 1.60 2.61 1.29 5.80 0.80 16 56 7.43\t48.55 1.856.69 19.46 24.46 47.60 6.99 84.72 171.60 371.38 252.69 Chertsey.\t23.52\t56.39\t1.60\t81.51 Chertsey.\t4.20\t8.56\t1.56\t14.32 Chertsey.Chertsey.Chertsey.\t82.00 8.40 28.00\t234.26 6.50\t14.87 1.60\t331.13 16.50 28.00 Chertsey.\t115.20\t45.70\t5.35\t166.25 Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.\t20.00 16.00 3.08 8.40 15.40\t57.14 45.69 7.93 16.27\t3.62 1.60 2.40\t80.76 61.69 12.61 10.80 30.67 Chertsey.\t6.00\t28.57\t2.74\t36.31 Chertsey.Chertsey.\t34.00 , 14.00\t36.73 36.07\t2.40 3.45\t73.13 53.52 Chertsey.\t116.00\t331.38\t19.80\t467.18 166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 101- année, n\" S Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (.continued) Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Rang Range Canton Township Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Frais et intérêts Costs and int.Hamelin Fernand & Rossi S.Hudon, Fernand.Investment C.C.Jardin St-Théodore Juteau, Rosaire.Laplante, Roger &/ Yvon.Martigny Noël & Al.Martin, Leopold.Martin, René.Martineau, Joseph G.Meilleur, Claude.,.Monette, Robert.Morin, Paul.v.Plante, Fernand.Plante, Léonce & Al.Poirier, André.Pouplier, André & Uxor.Raymond, André.Riportella, Ferdinand.Riportella, Ferdinand.Riportella, Ferdinand.Roy, Jean Claude.Skêlly, Peter.i.Neveu Succ.Misael.Sylvestre, Benoit.Taillon, Lionel.r.Therrien, Normand.*.Trottier, Gabriel.Zabartany Vassef.Wanca.William.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.39 s 271.272, 273.274, 275, 276,307, 308, 311, 312,319,320, 327,328, 339, 340, 346, 347, 348 & 349.P.12.25 s 52 et 53.¦.7As2, 3, 5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 15.16, 19, 20, 17, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27,28,30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39,40,41,42,43.P.39.37 s 66.39 s 295 et 296.,.39 s 396.35 s 77.38 s 285 et 287.P.5A.39 s 313 et 314.P.Ub.,.35 s 65.i.38 s 237 et 238.P.14 et P.15.39 s 253 et 254.38 s 170.38 s 293, 295.297 et 299.38 s 266, 267 et 268.P.19A.37 s 161 et 162.36 s 8 et 9.P.47.53.18 s 6.P.14.37 s 116 et 118.Bloc C27 s D8, 12, 16, 18, et 21, P.35.P.17.P.28A et P.29.38 s 1 et 2.39 s 277.278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 301; 35 s 39 et 40.39 s 369, 370, 371,372, 381, 400, 407.408 et 409.29A s 116 et 117, 30A s 1, 2, 3.38 s 350, 351.354, 39-s 27, 28.30.183, 337 et 338.29C s 114.115, 116, 117, 118, 143, 144 et 145.37 s 78.29Cs 1,2,3,4, 107, 127 et 128; 37 s 117 et 119.28 s 88, 90, 100, 101, 102, 121, 132.133, 134 29Cs 104, 105 et 106.28 s 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.28 s 1, 7, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 141, 143, 144, 145 et 146.29Cs5.6,7,8, 11, 108, 6.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.S 38.92 33.60 48.00 155.96 14.00 88.10 \u2022 5.60 4.76 4.76 11.20 2.80 16.00 4.20 3.92 23.00 3.92 1.96 24.00 13.72 298.00 40.00 6.00 14.00 22.40 14.00 22.40 4.00 142.40 20.00 112.00 33.88 35.00 36.40 24.08 20.16 18.20 33.60 36.40 42.00 40.60 8 100.27 53.16 138.61 347.67 36.07 145.87 11.43 7.31 9.73 22.85 6.95 45.70 8.56 6.42 84.77 8.00 5.33 86.57 38.45 657.07 162.27 17.15 57.70 36.07 37.48 9.93 112.64 57.14 288.54 95.22 104.93 152.49 51.93 46.90 86.58 93.77 108.21 111.49 g 7.47 3.20 1.60 24.71 4.00 2.40 2.52 .80 3.22 2.40 1.42 3.75 2.36 .80 6.18 2.32 .80 5.34 2.89 .80 9.55 2.06 .80 6.15 3.49 3.68 1.58 .80 4.42 21.58 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 167 Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Terres Laurentiennes Inc.Immeubles Chertsey Ltée.t.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.29A s 1, 2, 3.4, 5, 6, 7,8, 38, 39,40,41,42, 43, 44,45, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 140, 141, 142, 143, 147, 148, Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre 109, 110,111, 112, 113.123, 124, 125, 126.38 s 8, 39 s 1,2,29, 158, 159, 325, 326, 342, 343.38 s 11, 12,228,231, 320 et 321, 39 s 93, 94, 114,250, 255, 266 et 267.28 s 59, 61,62, 63,64, 65,66,67,68,70,71, 72, 73, 74, 75 et 103.28 s 147 et 148; 38 s 28, 29, 255, 356, 322 et 323; 39 s 302 et 249.35 s 56, 58, 59 et 60.P.14-.P.9 et 10.P.35.P.36 s 101.28 s 60 et 123, 29C s 103 37 s 120.121 et 123.P.15 et P.17A;39s382.35 s 7.29 s 13,39 s 186, 187, 210 et 211, 38 s 75.Rang Range 5.g.6.8.8.6____¦.7.5; 7.7.7.Canton Township Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Chertsey.Taxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costa and int.\tTotal $ 16.52\t$ 45.27\t\t$ 61.79 24.36\t72.04\t\t96.40 47.60\t127.67\t\t175.27 21.00\t96.94\t\t117.94 8.96 90.23\t13.05\tS .80\t22.01 91.03 12.60\t479.72\t\t492.32 49.60 35.70 16.36\t124.68 75.24 40.68\t.80\t174.28 111.74 57.04 413.56\t840.23\t\t1,253.79 Chertsey.9.10, 11, 13.14, 15.16, 17, 18, 19.20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.30, 31, 32, 33.34,35,36,37., 46, 47, 48, 49, 50, 51.52.53, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121.122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée.39 s 100, 101, 110, 119, 228 et 229.16 s 16, 17,23.29, 30, 31,39,40,41,42,43, 46, 47, 48, 52, 61 et 62.16 s 63, 66, 71,80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 95, 17A s 2 et 3.16 s 38 et 92, 17A s 4, 5,6,7, 19,24,25,26, 27, 28, 29, 30 et 31.28 s 20, 21,22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36.28 s 37, 38, 39.40.41.42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50,51,52,53.54,69,81,86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 127, 128, 129, 130, 131.136.137, 138.25 s 78, 79, 80, 81,82, 85, 86, 87, 88, 89.90, 91.92,93.94,95, 96.99.100.101, 102.103 et 104, 26 s 2, 3.4, 11, 12, 31.32, 33.29 s 2.6, 12, 16,17,24, 25,26,35s 1,3,5, 11, 36 s 10.29 C s 12, 23, 24, 25.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41,42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 7.\tChertsey.\t10.08\t26.99\t 5.\tChertsey.\t52.64\t135.60\t 6.\tChertsey.\t50.96\t131.28\t 6.\tChertsey.\t36.66\t91.63\t 5.\tChertsey.\t84.00\t216.41\t 5.\tChertsey.\t126.00\t324.62\t 7.\tChertsey.\t63.28\t163.01\t1.60 7.\tChertsey.\t79.52\t207.39\t 5.\tChertsey.\t259.28\t667.96\t 36.07 188.24 182.24 127.19 300.41 450.62 227.89 286.91 927.24 168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames Immeubles Chertsey Ltée.Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .ImmeublesChertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée .Immeubles Chertsey Ltée Immeubles 50-50 Ltée Immeubles 50-50 Ltée .Immeubles 50-50 Ltée Immeubles 50-50 Ltée Immeubles 50-50 Ltée- Immeubles 50-50 Ltée .Numéro du lot\t et du cadastre\tRang Number of lot\tRange and cadastre\t 51, 52, 53, 54, 55, 56,\t 57, 58, 59, 60 à 102\t inclus 119, 120.121.\t 122, 129 à 142 inclus.\t 36 s 5.6, 7.10.11, 12,\t8.15 et 16.17, 18, 19 et\t5.22; 16 s 15.\t 17As32,35, 37,38,39.40,\t5.43, 44.\t 28 s 8, 11, 12, 17, 18, 19.\t 31 s 1,3, 4.5, 6, 8, 9.10\t6.11, 13.14.15, 16, 17, 18\t 19, 20.22, 23, 24, 25, 26\t 27, 28, 29.30, 31, 32\t 38 s 117, 155.156.\t7 39 s 41.42, 43, 44,45,\t 46, 47, 50, 51, 54, 55,\t 59, 60, 63.\t 28 sl39, 140, 142, 157 .\t5.37 s 44, 52, 53.68.173.\t7 219.\t 39 s 175.176, 242.243.\t7.268, 269, 341.354.\t 25 s 27, 28.29, 30, 32,\t7.33, 34, 35, 36, 37.38.\t 39, 42, 43, 54, 57, 58,\t 59, 60, 61.63, 64, 65,\t 66, 67, 68, 70, 71, 72,\t 73, 74, 75.76, 77.\t 30As4,6, 7, 8, 9, 10, .\t5.11,12, 13, 14, 16.17,\t 18, 19, 20, 21, 22.27,\t 29, 30, 31, 32, 33.\t 29 s 8, 9, 10, 11, 20, 21\t7.25 s 14, 21, 22.\t P.30.\t6.P.26.\t7.P.25.\t 37 s 197, 198 .i.\t7 38 s 334, 335, 336,337,\t 73.\t 39 s 35, 36, 37, 38, 39, .\t 40.\t 35 s 49.\t8 36 s 2.\t P.30A.\t5,.P.29 et P.39.\t7 39 s 180.\t7 .35 s 1.4,8.\t8.38 s 37, 38, 49, 50, 157,.\t7.158, 163, 183.286, ?92.\t7 38 s 164, 165, 166.167, .\t7 .303, 314, 326, 327, 328.\t 39 8 66:182.\t 39 s 67, 68, 96, 107.108,\t7.161, 162, 164, 165, 179.\t 233.\t 29 s 3, 4, 14, 15.\t7.36 s 9.\t 35s 6, 8, 9.\t8 37 s 51, 105, 109, 111,\t7.135, 189.\t 38 s 35.36, 283,284,\t 301, 356.\t7 39 s 163.\t7 Canton\tTaxes munie.\tTaxes scolaires\tFrais et intérêts\tTotal Township\tMunie, taxes\tSchool taxes\tCosts and int.\t Chertsey.\t8 53.48\tS 173.89\t\tS 227.37 Chertsey.\t57.40\t124.29\t\t181.69 Chertsey.\t105.00\t237.43\t\t342.43 Chertsey.\t44.80\t124.52\t\t169.32 Chertsey.\t18.34\t52.07\t\t70.41 Chertsey.\t15.68\t40.43\t\t56.11 Chertsey.\t72.24\t228.16\t\t300.40 Chertsey.\t58.80\t167.21\t\t226.01 Chertsey.\t40.32\t28.57\t\t68.89 Chertsey.\t95.50\t319.25\t\t415.55 Chertsey.\t29.58\t139.60\t\t169.18 Chertsey.\t139.21\t603.74\t\t742.95 Chertsey.\t69.16\t178.17\t\t247.33 Chertsey.,\t22.68\t64.62\t\t87.30 Chertsey.\t44.80\t115.41\t\t160.21 Chertsey.\t19.88\t51.20\t\t71.08 Chertsey.\t25.28\t73.61\t$ .80\t99.59 Chertsey.\t28.50\t75.17\t\t103.73 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 169 Corporation municipale de la paroisse de Chertsey et du canton Wexford (suite) Municipal Corporation of the Parish of Chertsey and Township Wexford (continued) Noms et prénoms Names and surnames\tNuméro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre\tRang Range\tCanton Township\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal Brassard, Marie Josée.\t39 s 375, 376, 378,391, .392, 394, 395, 397, 398, 399,401,402,403.35 s 61, 62, 63, 64, 66,.67, 68, 69, 70, 71, 72, 75,78, 79,80,81.\t7.8\tChertsey.\tS 100.52\t$ 258.87\t\t$ 359.39 Corporation municipale de la paroisse de St-Jacques \u2014 Municipal Corporation of the St.Jacques Parish\t\t\t\t\t\t\t Mathieu, Gcorgcs-Éticnne .\tP.692 et 699 et 737.\t\tParoisse .St-Jacques\tS 64.89\tS 357.62\tt 14.74\t$ 437.25 Corporation municipale de Notre-Dame de la Merci \u2014 Municipal Corporation of Notre-Dame de la Merci\t\t\t\t\t\t\t Thibault, Armand.Tremblay, Philippe\tP.6,.p.n.39b s5.30A s 153.30As63 &64.\t3.7.6.11 11.\tChilton.Chilton.Chilton.Chilton.Chilton.\t\t$ 19.62 82.68 167.01 66.43 16.00\tS 6.78 7.92 14.77 5.26 4.27\tS 26.40 90.60 181.78 71.69 20.27 Corporation municipale du ¦ Lac Paré > \u2014 Municipal corporation of the \"Lac Paré\" Ares, Napoléon.Brisson, Lucien.Bidal, Mlle Francine .Delorme, Jean-Guy .Jacques, Albert.Dupere, Philippe,.Fontaine, Major.Fortin, Jean-Paul.Girard, Marcel.Jaccottey, J.L.Lacombe, Lucien.Laplante, Victor.Mascool, Alwin.Ouimet, Gérard.Proulx, Hubert.Riportella, Ferdinand.Sirois, Dame Ben/jit.St-Jean, Y von.Tremblay, Aline.Wiedman, Roland.Maynard, Jean.Lavoie, Armand.Renzetti.Dame El.Heins, James.Les Terres Laurentiennes Archambault, Marcel.Beaudry, Jean-Pierre.Laurencelle, Rodolphe.Lebel.Réal.Punde, Peter.Sanos, Jean.Nadon, Gérard.Durand, Marguerite.Letendre, Jérôme.Miron, Arthur.Domaine Bois Franc Inc.Tremblay, Jean-Guy.24s 110, 111, 112.113, 114, 115, 116, 117 & 118.19 s 3, 6.23 s 250.19s 181.19 s 181,96, 97, 100 et .101 24 s 490 & 503.19 s p.435 & 436.21 s 14.24 s 16, 162, 163, 164____ 23 s 129, 130, 131.24 s 13, 14.19 s 599.22 s 205, 206.22 s 67.16 s 86, 87, 88.19 s 313.24 s P.361.19 s 275.24 s 519, 520.17 s 98.19 s 1,2.17 s 41.24 s 77.16s 121.16 s 23.19 s 680, 681.17 s 104.24 s 203.17 s 45, 46.24 s 26.24 s 64, 76.19 s 634, 635, 636, 637 .24 s 392, 393.P.24.P.22.P.18.P.18, P.19, P.20, P.21.P.21.7.\tChertsey.\t\tS 382.07\t\t$ 382.07 8.\tChertsey\t\t\t\t 7.\tChertsey.\t\t52.69\t\t52.69 7.\tChertsey.\tS 6.00\t18.37\t\t24.37 7.\tChertsey.\t\t47.44\t\t47.44 7.\tChertsey.\t\t45.26\t\t45.26 7.\tChertsey.\t\t206.74\t\t206.74 8.\tChertsey.\t\t221.48\t\t221.48 7.\tChertsey.\t\t283.43\t\t283.43 7.\tChertsey.\t\t648.62\t\t648.62 7.\tChertsey.\t36.31\t118.10\t\t154.41 7.\tChertsey.\t13.28\t55.13\t\t68.41 7.\tChertsey.\t\t79.60\t\t79.60 7.\tChertsey.\t43.59\t192.88\t\t236.47 6.\tChertsey.\t\t406.71\t\t406.71 7.\tChertsey.\t\t12.05\t\t12.05 7.\tChertsey.\t\t418.87\t\t418.87 ?.\tChertsey.\t\t18.37\t\t18.37 7.\tChertsey.\t\t91.65\t\t91.65 6.\tChertsey.\t\t318.26\t\t318.26 7.\tChertsey.\t10.18\t36.73\t\t46.91 6.\tChertsey.\t34.76\t222.75\t\t257.51 7.\tChertsey.\t10.18\t23.84\t\t34.02 6.\tChertsey.\t72.45\t162.49\t\t234.94 6.\tChertsey.\t\t224.43\t\t224.43 7.\tChertsey.\t22.73\t188.64\t\t211.37 6.\tChertsey.\t6.63\t\t\t6.63 7.\tChertsey.\t9.82\t\t\t9.82 6.\tChertsey.\t14.68\t36.89\t\t51.57 7.\tChertsey.\t32.81\t85.81\t\t118.62 7.\tChertsey.\t19.20\t\t\t19.20 7.\tChertsey.\t10.48\t16.76\t\t27.24 7.\tChertsey.\t47.08\t70.12\t\t117.20 7.\tChertsey.\t\t343.41\t\t343.41 8.\tChertsey.\t\t311.64\t\t311.64 6.\tChertsey.\t\t71.19\t\t71.19 8.\tChertesy.\t413.86\t874.85\t\t1,288.71 7.\tChertsey.\t\t102.51\t\t102.51 170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Corporation municipale de Ste-Julienne \u2014 Municipal Corporation of Ste.Julienne Noms et prénoms Names and surnames\tNuméro du lot ,et du cadastre Number of lot and cadastre\tParoisse Parish\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scolaires School taxes\tFrais et intérêts Costs and interests\tTotal \tP.806.\tSte-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.Ste-Julienne.\t$ 54.25 48.40 43.40 94.95 2.80 33.85 266.46\tS 141.13 177.42 81.68 26.55 369.82 9.78 212.08 830.39\t\t* 214.88 177.42 129.98 69.95 464.77 12.58 245.93 1,096.85 DiLena Frank et Giovanni & Al.,.\tP.550.62 s 1 à 14.200 .\t\t\t\t\t \t598.P.818.\t\t\t\t\t No de lot et cadastre \u2014 Lot and cadastre No.: 873 s 4 et 874 s 6, 7, 8, 876 s 9, 10, 11, 13.14, 15.17, 18, 24, 27; et 877 s 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25; et 881 s 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21; et 882 s 20, 21, 24, 26, 27, 28.35.36.37, 4 24; et 884 s 22 à 33 inclus et 51 à 61 inclus.15, 17, 20.35, 36, 39, 40.41.42.et 886 s 3.4, 6, 7.8, 10, 11, 12; et 887 s 2, 3; et 889 s 7, 8.9, 12, 13 et 14.L'Espérance, André Succ.Moskaluk, Stefan.Pilarezik, Joseph.Robert, Pierre.Tellier, Moise Succ.ou inconnu a/s Alban-Majeau.Turcotte, Maurice.iu, 14, io, 17 et sva s o, o, y, », a, u, vt.i.s; et et 878 s 7, 9.10, 11, 17.18, 19, 26, 6; et 880 s 7; 11, 42, 49.52, 54, 66, 67.et 883 s 5, 6, 7.8, 22, 23, 44.46, 48, 66, 67; et 885 s 4, 7, et 13 à 21 inclus; Ste-Julienne.19.80 20.50 20.00 34.80 52.11 144.17 24.97 4.05 141.43 Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre \t\tTaxes\tTaxes\tFrais et\t\t Rang\tCanton\tmunie.\tscolaires\tintérêts\t\t \t\t\t\t\t\tTotal Range\tTownship\tMunie.\tSchool\tCosts\t\t \t\ttaxes\ttaxes\tand int.\t\t 1.\tKilkenney.\t3 54.99\t8 46.45\t\tS\t101.44 1.\tKilkenney.\t103.14\t\t\t\t103.14 2.\tKilkenney.\t22.89\t4.95\t\t\t27.84 2.\tKilkenney.\t25.15\t5.55\t\t\t30.70 2.\tKilkenney.\t40.53\t6.78\t\t\t47.31 2.\tKilkenney.\t74.22\t11.48\t\t\t85.70 2.\tKilkenney.\t63.18\t110.99\t\t\t174.17 2.\tKilkenney.\t45.29\t37.21\t\t\t82.50 2.\tKilkenney.\t10.53\t10.63\t\t\t21.16 2.\tKilkenney.\t39.66\t29.75\t\t\t69.41 3.\tKilkenney.\t157.51\t197.50\t\t\t355.01 3\tKilkenney.\t140.99\t13.03\t\t\t154.02 3.\tKilkenney.\t19.63\t2.25\t\t\t21.88 3.\tKilkenney.\t42.07\t7.38\t\t\t49.45 3.\tKilkenney.\t40.83\t7.00\t\t\t47.83 3.\tKilkenney.\t192.66\t197.13\t\t\t389.69 3.\tKilkenney.\t\t66.25\t\t\t66.25 3.\tKilkenney.\t42.77\t42.30\t\t\t85.07 3.\tKilkenney.\t64.30\t10.95\t\t\t75.25 4\tKilkenney.\t55.50\t46.44\t\t\t101.94 4.\tKilkenney.\t70.43\t11.63\t\t\t82.06 4.\tKilkenney.\t102.62\t127.31\t\t\t229.83 4.\tKilkenney.\t76.99\t68.03\t\t\t145.02 4.\tKilkenney.\t56.54\t45.88\t\t\t102.42 5\tKilkenney.\t82.08\t\t\t\t82.08 6.\tKilkenney.\t26.98\t16.65\t\t\t43.63 5.\t, Kilkenney.\t13.39\t8.62\t\t\t22.01 5.\tKilkenney.\t10.00\t9.63\t\t\t19.63 5.\tKilkenney.\t16.86\t\t\t\t16.86 5.\tKilkenney.\t22.79\t1.15\t\t\t23.94 5 .\tKilkenney.\t11.17\t10.76\t\t\t21.93 5\tKilkenney.\t10.00\t8.85\t\t\t18.85 5.\tKilkenney.\t90.62\t\t\t\t90.62 6.\tKilkenney.\t10.63\t\t\t\t10.63 Claire chamberland Gascon.St-Germain, Ernest.Fontaine, Jacqueline Varin.Fontaine, Jacqueline Varin.Fontaine, Marcel.Bureau, Fernand.Dorais.Vve René.Riccuito.Alfred.Riccuito, Alfred.Laurent, Gilbert.Lalonde, Adrien.Lacombe, Geo Aimé.Lacombe, Geo Aimé.Guy, Jean.Gagné, Roland.Boudreau, Gilles.Crédit Duvernay Inc.Young, Robert.Demontigny, Real.Bernard, Marcel.Massé, Real.Goulet, Claudette.Robichaud, Léonard.Couture, Maurice.Gaudreou, Aldège & Ux.Beaudoin, Roger.Beaudoin, Roger & Ux.DaPonte, Antonio.Madarasz, Itsvan.Fried, Andrew.Laslow, Horvath.Borlas ou Borbas, Elizabeth.Lamoureux.Jacques D.!.Lamoureux, Dme Jacques D.P.9A.P.8c.P.HAet 11c.P.11c.P.llAet 11c.P.12.P.12.P.12.P.12.P.12.lOAs 19.lib s 668, 669.lib s 670.P.lib.P.lib.P.11c.P.11c.P.11c.12 s 14.P.9d & P.10A P.10c.P.15A.P.20c.P.20d.P.9b.P.9b.P.9A.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 197S, Vol.101, No.S 171 Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte (suite) \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish (Continued) Noms et prénoms Names and surnames Budai, Leslie.Rover.Giovanni.Szelid.Imre.Langlois, Romuald.Vincent, Richard.Brosseau, Bernard.Boudreau, André.Micholkow S et Hedvig Stor-mer.Riendeau.Robert.Meunier.Dme Marcel.Landry, Jean-Paul.Bérubé, Jean-Paul.Rochon, Raymond.Rochon, Raymond.Légaré, Pauline.Boisvert, Marc.Sakalosky, Jeanne.Lauzon, Jean-Pierre ce Maurice.Paquette, Dme René.Cantin, Claude.Perron, Normand.Rioux, André.Labonté, Léon.Labonté, Léon.Théoret, Armand.Girard, Gaston.Gérard, Roland.Gérard, Roland.Protasow, Alex.Paccito, Sylvio .Scardere, Alfred.Scardere, Alfred.Scardere, Alfred.Bergeron, Jean.Sumuierside, Louis.Bibeau.Emdien.Daigneault.Huguette.Perron.Michel S.Cyr, Marie-Madeleine.Dagenais, Aldor.Dagenais, Aldor.Gendron, Marcel.Corbeil.Marcel.Dumas, Gérard ou Dumai.Langlois, Michel Watson.Picard, Gérard.Sakalosky, Jeanne.Walden, Jolin.Bastien, Bruno.Bastien, Bruno.Richard, Arthur.Watson, Suoc.John.Delumirande, Dme J.Ls & Al Laporte, Emile.Bélair.Hervé.Club Sky nautique du Lac Connolly Inc.Laporte,Rodrigue.Bourque, Gerry.Duchesne, Dme Marie CM.Thincl, Dme Lucienne.Labrosse, André.Désormeaux, Florian.Daigneault, Arthur.Lavallée.Rosaire.De La Penna Dominico.Les Ent.Décarie Inc.' Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.9a.P.10A.P.10a.P.he.P.HE.13A s 10.13As 17.P.17a.P.17a.P.17c.P.17a.P.17c.P.18a.P.18a.P.18a.P.18a.P.18a.P.18c.P.18c.P.20b.P.20b.P.28a.P.28a.P.27a et P.25a.'.P.28a.P.28a.:.la, lb & lc.4a s 19.P.5b.P.5b.P.6b rang et lot 6c.P.8b.P.8d.P.8d.P.8d.P.8d.P.9a.10a s 3.P.13b.P.16b.P.10A.P.10a.P.10a.P.10a.P.21a.P.27.P.27.P.27.29a s P.2.29a s 46 à 49 et s 54 à 58 29a s 61.P.29b.P.29b.P.29b.P.30.P.29b.P.12a.12a s 72.14b-14c-14e-14f.\t\tTaxes\tTaxes Rang\tCanton\tmunie.\tscolaires Range\tTownship\tMunie.\tSchool \t\ttaxes\ttaxes 6.\tKilkenney.\t?10 50\t3 16.68 5.\tKilkenney.\t37.76\t3.66 6.\tKilkenney.\t83.97\t127.96 6.\tKilkenney.\t66.48\t76.47 S.\tKilkenney.\t19.80\t19.18 5.\tKilkenney.\t22.14\t15.90 6.\tKilkenney.\t56.31\t 5.\tKilkenney.\t34.98\t36.18 5.\tKilkenney.\t12.25\t 5.\tKilkenney.\t210.41\t16.80 6.\tKilkenney.\tM.26\t67.20 6.\tKilkenney.\t21.52\t 5.\tKilkenney.\t12.67\t22.94 5.\tKilkenney.\t¦10.81)\t61.23 8.\tKilkenney.\t11.43\t10.60 6.\tKilkenney.\t11.17\t S.\tKilkenney.\t11.17\t1.25 5.\tKilkenney.\t67.66\t10.80 5\tKilkenney.\t11.17\t10.45 5.\tKilkenney.\t11.03\t2.25 6.\tKilkenney.\t11.17\t13.04 5.\tKilkenney.\t77.50\t107.08 5.\tKilkenney.\t5.91\t 5.\tKilkenney.\t10.67\t5.05 5.\tKilkenney.\t15.64\t27.70 6.:.\tKilkenney.\t123.92\t92 52 8.\tKilkenney.\t8.98\t8.62 5.\tKilkenney.\t38.13\t30.40 5.\tKilkenney.\t82.60\t69.65 5.\tKilkenney.\t11.55\t1.48 6.\tKilkenney.\t40.29\t64.20 6.\tKilkenney.\t264.90\t371.67 6.\tKilkenney.\t26.30\t111.81 6.\tKilkenney.\t57.04\t65.30 6.\tKilkenney.\t60.88\t57.53 a\tKilkenney.\t139.68\t95.66 6.\tKilkenney.\t63.41\t e.\tKilkenney.\t55.31\t46.96 7.\tKilkenney.\t49.38\t8.18 \tKilkenney.\t121.84\t148.79 6.\tKilkenney.\t83.12\t222.88 6.\tKilkenney.\t82.10\t14.38 6.\tKilkenney.\t178.02\t162.46 6.\tKilkenney.\t120.96\t11.18 e.\tKilkenney.\t48.86\t40.40 6.\tKilkenney.\t24.01\t29.85 6.\tKilkenney.\t23.82\t24.53 7.\tKilkenney.\t35.87\t67.16 7.\tKilkenney.\t56.02\t47.45 7\tKilkenney.\t48.35\t29.88 7.\tKilkenney.\t35.26\t49.61 7\tKilkenney.\t26.88\t6.23 7.\tKilkenney.\t125.18\t20.78 7.\tKilkenney.\t19.05\t10.28 7.\tKilkenney.\t170.06\t 7.\tKilkenney.\t150.91\t20.46 7.\tKilkenney.\t650.44\t161.91 7.\tKilkenney.\t62.72\t30.16 7.\tKilkenney.\t104.67\t110.54 7.\tKilkenney.\t44.77\t4.20 7.\tKilkenney.\tMi W)\t 7.\tKilkenney.\t21.26\t 7.\tKilkenney.\t90.84\t12.83 8\tKilkenney.\t126.31\t178.20 8.\tKilkenney.\t83.89\t16.63 8.\tKilkenney.\t160.87\t128.26 Frais et intérêts Costs and int. 172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier i97S, 10k' année, n° S Corporation municipale de la paroisse de St-Calixte (tuile) \u2014 Municipal Corporation of St.Calixte Parish (continued) Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Rang Range\tCanton Township\tTaxes.munie.Munie, taxes\t\tTaxes scolaires School taxes\t\tFrais et intérêts Costs and int.\tTotal\t 9.\tKilkenney.\tS 39\t66\t8 60\t24\t\t\t99.90 9\tKilkenney.\t113\t42\t10\t21)\t\t\t123.62 9.\tKilkenney.\t74\t94\t12\t48\t\t\t87.42 9.\tKilkenney.\t47\t33\t38\t88\t\t\t86.21 9.\tKilkenney.\t99\t17\t114\t05\t\t\t213.22 9.\tKilkenney.\t66\t24\t1\t98\t\t\t68.22 9.\tKilkenney.\t11\t32\t16\t88\t\t\t28.20 9.\tKilkenney.\t13\t59\t\t\t\t\t13.59 9.\tKilkenney.\t49\t33\t24\t38\t\t\t73.71 9.\tKilkenney.\t18\t76\t9\t50\t\t\t28.26 9.\tKilkenney.\t46\t50\t18\t70\t\t\t65.20- 9.\tKilkenney.\t110\t06\t9b\t10\t\t\t206.16 9.\tKilkenney.\t126\t71\t112\t22\t\t\t238.93 9\tKilkenney.\t12\t57\t\t\t\t\t12.57 9.\tKilkenney.\t74\t81\t58\t92\t\t\t133.73 9\tKilkenney.\t11\t55\t21\t20\t\t\t32.75 9.\tKilkenney.\t78\t27\t112\t81\t\t\t191.08 9.\tKilkenney.\t82\t10\t174\t24\t\t\t256.34 9.\tKilkenney.\t43\t24\t4\t13\t\t\t47.37 9.\tKilkenney.\t107\t71\t114\t01\t\t\t221.72 9.\tKilkenney.\t53\t42\t\t\t\t\t53.42 10\tKilkenney.\t33\t52\t\t\t\t\t33.52 10\tKilkenney.\t31\t48\t\t\t\t\t31.48 10.\tKilkenney.\t81\t58\t72\t00\t\t\t153.58 10.\tKilkenney.\t61\t65\t53\t17\t\t\t114.82 10\tKilkenney.\t55\t47\t\t\t\t\t55.47 10\tKilkenney.\t42\t73\t34\t37\t\t\t77.10 10\tKilkenney.\t37\t41\t32\t50\t\t\t69.91 xi____\tKilkenney.\t117\t76\t101\t77\t\t\t219.53 xi.\tKilkenney.\t81\t08\t71\t53\t\t\t152.61 SI.\tKilkenney.\t118\t91\t207\t42\t\t\t326.33 xi.\tKilkenney.\t87\t71\t15\t45\t\t\t103.16 xi____\tKilkenney.\t124\t67\t111\t31\t\t\t235.98 xi.\tKilkenney.\t19\t82\t\t\t\t\t19.82 XI\tKilkenney.\t56\t32\t27\t71\t\t\t84.03 xi.\tKilkenney.\t48\t45\t38\t60\t\t\t87.05 xi.\tKilkenney.\t70\t24\t12\t86\t\t\t83.10 xi .\tKilkenney.\t12\t88\t2\t90\t\t\t15.78 xi____\tKilkenney.\t13\t58\t18\t43\t\t\t32.01 xi____\tKilkenney.\t112\t04\t17\t74\t\t\t129.78 xi____\tKilkenney.\t11\t03\t\t\t\t\t11.03 xi____\tKilkenney.\t57\t00\t155\t34\t\t\t212.34 xi____\tKilkenney.\t66\t76\t11\t48\t\t\t78.24 xi.\tKilkenney.\t66\t76\t\t\t\t\t66.76 xi.\tKilkenney.\t\u2022 23\t53\t22\t77\t\t\t46.30 xi.\tKilkenney.\t72\t06\t1\t24\t\t\t73.30 xi____\tKilkenney.\t103\t05\t22\t46\t\t\t125.51 xi____\tKilkenney.\t90\t28\t80\t42\t\t\t170.70 xi____\tKilkenney.\t93\t85\t87\t37\t\t\t181.22 xi____\tKilkenney.\t112\t29\t10\t20\t\t\t122.49 xi .\tKilkenney.\t22\t27\t4\t35\t\t\t26.62 xi.\tKilkenney.\t11\t03\t10\t45\t\t\t21.48 xi____\tKilkenney.\t32\t00\t\t\t\t\t32.00 xi.\tKilkenney.\t118\t14\t128\t35\t\t\t246.49 xi.\tKilkenney.\t24\t48\t23\t73\t\t\t48.21 xi____\tKilkenney.\t37\t11\t\t\t\t\t37.11 xi____\tKilkenney.\t20\t66\t\t\t\t\t20.66 Levesque, Dme Delphis.Bisaillon, Guy.1 on liner, Jobaphat.Tessier.Georges.Smith, Stanley.;.Konta, Marguerite.Carrier, Robert.Laprise, Jean-Guy.Bouchard, Gaston.Duchesne, Dme Pierrette.Guillet, Jeannette.Addy, Norbert.Addy, Norbert.Prévost, Ludger.Proulx, Gloria Kenny.Bissou, Bulite.Bisaillon, Raymond.Gauthier, Jacques.Beaudet, Simone.Leroux.Claude.Patry, Claude.Hoyos, Camille & Zajdman A.Hoyos.Camille.Marie Rose Gagné Villeneuve Emard, Hubert.Therrien, Dme Jean.Lecompte, J.P.Léonard, Claude.Houle, Armand.L'Heureux, Jacques.Lafrance, Dme Jean-Paul.Lanouette.Lucien.Dajerling, Hans J.& U.Lapalme, Jean-Paul.Poirier, Denis Maurice.Desjardins, Yvan.Laxson, Vve Françoise.Laxson, Vve Françoise.Stanley, Murray.Wendell Simpson & Ux et Heapy Arthur.Provost, Succ.a/s Monique & Marcel Provost.Kinsella.Edward.Davies.Douglass.Parent, Roger.Cartier, René .Bourque.Dine Jacques.Derepentigny, Claude Phi & Rosaire.Lambert, Guy.Hébert, Jean-Louis.Messier, Yvon.Taillon, Jean-Marc.Grégoire, Rêjean.Bralant, Gérard.Beaudry.Mlle Marie.Laporte, Richard.Linchet, Léon.Renard, Alphonse.P.12a.P.11c.P.12a.12b s 7, 8.12b s 202.12b s 102.P.13a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.14a.P.15b.P.15a.P.15c et P.15d.P.15c et P.15d.P.15d.17c s 317.P.10a.P.9b.P.10a.P.12a.P.12a.P.12b.P.13c.P.3.P.3.4 s 163, 164, 165.5a s 15 & 16-1.5a s 93.5b s 183, 184.5d s 220.5b s 236 & 237.6c s 64 et 5d s 293.5c s 85, 90, 92 & 95.5c s 86 & 89.5d s 283.5c s 98, 101.5c s 117.5d s 235.5d s 352.P.7c.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.P.8.9b s 25.P.10a.P.10a.P.14a.P.13c.P.14a.Corporation municipale de la paroisse de St-Donat \u2014 Municipal corporation of St.Donat Parish \t\tC.\tLussier.\tS 21.36\t3\t32.02\t\tS 53.38 35.17 15.92 Ares, Clovis .\tP.40.\t4.\tLussier.\t35.17\t\t\t\t Bisonnette, Marie et Me Robert Dulude.\tP.34 .\t4\t\t6.54\t\t10.38\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 197Z, Vol.10L, No.S 173 Corporation municipale de la paroisse de St-Donat (suite) \u2014 Municipal corporation of St-Donat Parish (continued) Noms et prénoms Names and surnames Brisson, Robert.Brisson, Robert.Charbonneau, Gaétan.De Tonnancourt, G.G.Dubois.René.Hooton, Eric C.Lavoie, Ernest.Miller, Dme Larivière.Miller, Dme Larivière.Monette, Guy G.Monpain, Michel.Norman, Edgar Roy.Paré, Robert.Patenaude, Dme Eloi.Semeredy, Michela Arthur.Simoneau, Denis.Thibodeau, Jean.Poissant, J.M.Poissant, J.M.Poissant, J.M.Poissant, J.M.Poissant, J.M.Asselin, Dme Emile.Asselin, Dme Emile.Brisebois, Orner.Legendre.André Guy.Martin, Jean Marc.Morin Dme Carmel Boutin.Parent, Dme André.Villeneuve, Georges.Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre 40 & 41.39.P.b-1.18.41-46.P.27.P.21-1.28-2-40.28-2-41.38-76.14.7.12.70.24.40.41-20.41-2-8.41-2-9.41-2-17.41-2-27.41-13.P.1.P.2.P.30.P.30.P.31.P.31.P.10-C.P.10-C.Rang Range 6.5.1.1.4.Bloc G 3.3.3.3.d.C.Bloc E d.Bloc G Bloc F 4.3.3.3.3.4.6.1.1.1.1_____ 3.3.\tTaxes\t\tTaxes\t\tFrais et\t Canton\tmunie.\t\tscolaires\t\tintérêts\t \t\t\t\t\t\tTotal Township\tMunie.\t\tSchool\t\tCosts\t \ttaxes\t\ttaxes\t\tand int.\t Lussier.\t8 42\t98\t3 29\t13\t\t$ 72.11 Lussier.\t20\t20\t29\t13\t\t49.33 \t64\t47\t84\t42\t\t148.89 \t87\t58\t139\t28\t\t226.86 Lussier.\t3\t80\t6\t18\t\t8.98 \t182\t87\t\t\t\t182.87 \t320\t70\t379\t04\t\t699.74 Lussier.\t11\t18\t21\t63\t\t32.81 Lussier.\t10\t37\t21\t63\t\t32.00 \t94\t92\t\t\t\t94.92 Lussier.\t61\t15\t\t\t\t51.15 Lussier.\t76\t43\t186\t26\t\t262.69 \t125\t14\t134\t46\t\t259.60 \t282\t38\t685\t83\t\t967.71 Lussier.\t252\t27\t333\t26\t\t685.53 Lussier.\t\t\t102\t86\t\t102.86 \t23\t54\t25\t92\t\t49.46 \t3\t42\t18\t57\t\t21.99 Lussier.\t7\t52\t\t\t\t7.52 Lussier.\t7\t52\t\t\t\t7.52 Lussier.\t7\t52\t\t\t\t7.52 \t7\t52\t\t\t\t7.62 Archambaull\t24\t04\t\t\t\t24.04 Archambault\t41\t69\t\t\t\t41.69 Archambault\t80\t39\t\t\t\t80.39 Archambault\t207\t76\t452\t87\t\t660.63 Archambault\t62\t82\t\t\t\t52.82 Archambault\t88\t55\t\t\t\t88.55 Archambault\t30\t53\t30\t27\t\t60.80 Archambault\t48\t29\t61\t18\t\t109.47 Corporation municipale de la paroisse d'Entrelacs \u2014 Municipal corporation of Entrelacs Parish Archambault, Oscar.Demers, Dme Armand,.Hogue, Dme Denise.Redfern.Georges.Duclos, Dme Anita.Drouin, Melle Marcel- St Onge, Viateur., St Onge, Viateur.Trudel, Jean-Jacques Logée, O.Couroy, Y von.Sweeney, James.Sweeney, James., Scardere, Alfred.Sénécal, Robert.Cloutier, Jean-Marc.Sauvé, Roger.Portelance, Charles.Duval, Florent.Deschâtelets, Jérôme.Perreault, Mario & Gilles Riopel, Vve Roméo.Théoret, Melle Micheline 44 s 3, 4, 7, P.10, 20, 20-4,\t10\tWexford.\t$ 645.12\t3 505.68\t\t8 1,150.80 20-5, 20-6.\t\t\t\t\t\t P.10.\t8 Ch.\tChertsey.\t14.00\t0.59\t\t14.59 P.59.\t8 W.\tWexford.\t167.86\t\t\t167.86 P.47.\t10 W.\tWexford.\t22.41\t23.16\t\t45.57 P.6.\t8 eh.\tChertsey.\t96.75\t471.18\t\t567.93 P.7a.\t9 ch.\tChertsey.\t80.34\t\t\t80.34 44-12.\t10 W.\tWexford.\t90.75\t109.64\t\t200,39 44-18.\t10 W.\tWexford.\t85.55\t148.01\t\t233.56 P.57.\t8 W.\tWexford.\t89.90\t148.81\t\t238.71 P.2.\t8 ch.\tChertsey.\t49.12\t147.05\t\t196.17 P.8a.\t9 ch.\tChertsey.\t33.42\t63.79\t\t97.21 P.56.\t9 W.\tWexford.\t10.81\t12.57\t\t23.38 P.56.\t9 W.\tWexford.\t8.04\t21.31\t\t29.35 P.48.\t10 W.\tWexford.\t20.10\t32.70\t\t52.80 P.5 et P.6.\t7 ch.\tChertsey.\t133.84\t137.05\t\t270.89 P.10.\t8 ch.\tChertsey.\t18.41\t19.43\t\t37.84 P.48.\t10 W.\tWexford.\t668.32\t\t\t668.32 P.44.\tS W.\tWexford.\t40.00\t103.46\t\t143.46 P.2.\t8 ch.\tChertsey.\t97.56\t105.51\t\t203.07 \t9 ch.\tChertsey.\t56.67\t57.82\t\t114.49 P.54.\t7 W.\tWexford.\t50.96\t99.44\t\t150.40 44.\tXI W.\tWexford.\t46.32\t\t\t46.32 P.63.\t9 W.\tWexford.\t59.34\t181.41\t\t240.76 Corporation municipale du village de Rawdon \u2014 Municipal corporation of the village of Rawdon Barrie, Ernest.Daly, Robert.DeNotto.Dme I.Legault, Eugène.18F 2.17-33-1.16C-43.19-58-2 & 3 26.13 22.76 8.30 22.38 54.33 19.80 83.26 6.10 2.95 11.90 26.13 83.19 31.05 117.54 174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 10i' année, n\" 2 Corporation municipale du village de Rawdon (suite) \u2014 Municipal corporation of the village of Rawdon (continued) Noms et prénoms Names and surnames Numéro du lot et du cadastre Number of lot and cadastre Rang Range Canton Township Taxes Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Frais et intérêts Costs and int.Holoubek.Mrs.C.Masse, Dme J.Emile Sheehan, Patrick.Robinson.Ronald.Arnold, Wm.18A s 273, 274, 275.19-49-3.17-107-2.18b- 37-3.18A s P.325.6.6.6.6.6.Rawdon- Rawdon.Rawdon.Rawdon.Rawdon.98.13 1.40 65.60 187.43 70.48 189.12 89.55 346.96 153.45 47.25 $ 19.15 12.71 28.80 31.09 11.00 Donné à Sainte-Julienne, ce 5e jour de janvier 1972.43918-2-2-0 Le secrétaire du Conseil du Comté, Henri Dupois.Given at Sainte-Julienne, this 5th day of January 1972.Henri Dui'uis, 43918-2-2-0 Secretary of Council.Municipalité du Comte\" de Laprairie Je, soussigné, Gérard Péladeau, secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Laprairie, donne avis, par les présentes, que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique, au lieu où le Conseil de Comté tient ses Sessions, en la Ville de Laprairie, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures du matin, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus pour la vente.Municipality of the County of Laprairie I, the undersigned, Gérard Péladeau, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Laprairie, hereby give notice that the immoveables hereunder described will be sold by public auction, at the place where the sittings of the County Council are held, in the Town of Laprairie.on THURSDAY, the NINTH day of MARCH 1972, at TEN o'clock in the forenoon in default of payment of the taxes for which they are liable and the costs incurred for the sale.Ville de Laprairie \u2014 Town of Laprairie (Commission scolaire de la Ville de Laprairie) \u2014 (Laprairie School Board) Cadastre paroisse de Laprairie \u2014 Cadastre parish of Laprairie Propriétaire Proprietor Davron Association Ltd.Deneault succ, Lionel & Wilfrid Deneault succ, Lionel & Wilfrid Dupré, Clovis.Eatcho, Mounir.Langlois, Yvon.Perron, Dame Lucille Larivière.Rogerio Ferreira Da Costa.Antonio Marques Del Almeida.Manuel Furtado Da Silva.Circa, Antonio.Teufel, Alfred.Lots Nos Lots Nos 3.533.69.70.71.72.71.216.65.79.Cadastre P.344.P.203.P.202.35.364.P.364.673.539., 539.539.539.492.492.539.492.Taxes scol.School taxes 992.19 ,329.36 ,093.32 382.80 229.05 455.55 531.97 17.91 17.91 12.06 12.05 23.08 33.93 17.94 23.42 Int.$102.35 124.34 107.94 37.21 27.98 48.59 49.10 1.49 1.49 1.00 1.00 2.07 2.94 1.46 2.12 3 7.16 Taxes prot.Prot.taxes Int.$ 0.08 Taxes mun.Mun.taxes\tInt.\tTotal 3493.68\t$ 53.95\t31,654.41 120.00\t3.46\t1.577.16 775.20\t\t 100.00\t2.71\t2,130.93 243.30\t26.31\t 230\".00\t18.66\t938.28 102.00\t11.04\t370.07 106.50\t6.55\t617.19 169.10\t11.00\t 77.10\t2.35\t840.62 17.03\t1.19\t37.62 \t\t19.40 \t\t13.06 \t\t13.05 \t\t25.15 \t\t36.87 \t\t19.40 9.00\t0.98\t35.53 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10k, No.2 175 Ville de Brossard \u2014 Town of Brossard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie \u2014 Cadastre parish of Laprairie Nom du propriétaire Name of proprietor Lots numéros Lots numbers Cadastre \t\tTaxes\t Taxes\tTaxes\tscolaires\t munie.\tscolaires\tprotest.\t \t\t\tTotal Munie.\tSchool\tProtest.\t taxes\ttaxes\tschool\t \t\ttaxes\t \tS 174.42\t\t$ 174.42 \t15.70\t\t15.70 \t370.35\t\t370.35 356.93\t265.05\t\t621.98 \t499.95\t\t499.95 \t17.82\t\t17.82 \t103.00\t\t103.00 \t79.74\t\t79.74 297.01\t66.95\t\t363.96 \t333.00\t\t333.00 \t523.80\t\t523.80 26.90\t558.00\t\t584.90 234.59\t21.67\tS 4.54\t260.80 \t181.80\t\t181.80 \t89.18\t\t89.18 \t10.80\t\t10.80 \t255.60\t\t255.60 \t18.31\t\t18.31 432.03\t393.30\t\t825.33 \t285.30\t\t285.30 \t\t5.91\t5.91 276.22\t31.77\t\t307.99 373.94\t13.95\t\t387.39 \t85.95\t\t85.95 262.87\t24.66\t6.54\t294.07 262.87\t24.66\t\t287.53 262.87\t24.66\t6.54\t294.07 254.48\t23.17\t6.18\t283.83 400.01\t142.69\t2.20\t544.90 251.32\t23.53\t6.26\t281.11 251.32\t23.53\t46.92\t321.77 296.52\t18.31\t\t314.83 \t285.30\t\t285.30 \t11.59\t\t11.59 \t19.43\t\t19.43 268.56\t24.66\t6.54\t299.76 246.33\t46.31\t12.26\t304.90 290.88\t34.74\t\t325.62 233.51\t31.37\t8.35\t273.23 275.74\t32.87\t8.71\t317.32 218.37\t155.70\t\t374.07 \t4.95\t\t4.95 \t288.08\t\t288.08 \t13.50\t\t13.50 \t14.40\t\t14.40 \t13.95\t\t13.95 \t7.68\t\t7.68 228.38\t19.04\t5.08\t252.50 15.99\t34.20\t\t50.19 325.07\t82.80\t\t407.87 324.69\t82.80\t\t407.49 196.02\t31.05\t\t227.07 403.42\t97.11\t\t500.53 403.42\t97.11\t\t600.63 403.42\t97.11\t\t500.63 403.42\t97.11\t\t600.53 417.06\t25.78\t\t442.84 404.83\t24.28\t\t429.11 Horvath, Tibor.Charbonneau, A.Roger.Boulanger, Patrick.Caluori, Georges.Tremblay, J.-Maro.Boisvert, Gérard.St-Amond, Roméo.Guertin, Georges.Bédard, Raymond.Bouchard, Albert.Hébert, Réjean.Leblanc.André.Démontigny, Gérard.Brière, Emile.Babin.Jean-Marie.Long, Robert.Lefebvre, Raymond.Fontaine, Guy.Godbout, Ronald.Latour, Henri, Mme A\u2014 Allaire, J.-Ronald.Lavoie, Lucien.Perks, Ronald A.Bernier, Gabriel.Jurjo Miguel Angel.Lemaire, Guy.Von Kafalvy, Anna Marie Robert, Gilles.Duff Tyler, Charles-J.Boucher, Serge.Murray, Marie-France.Szczepkowski, Walter.Was, Joseph.Danilov, Stephen J.Allessandrini A.& al Arcand, Jean-Louis.Broka.Roger.Couillard, IIbald.Dufresne, Robert- Fortin, Robert.74.73.245.P.43, P.44, 124.357.P.34.P.14.P.66.P.8.4.8.25.156.60.127.333.599, 600.160.178.69.48.316.223.84.130.469.466.468.437.418.424.430.139.146.546-2.258.364.233.36.56.50.68.26.119.96.309 à 312.308.117-127____ 1201.1205.1206.1202.74.8.202.201.61.110.111.112.113.127.359.128.83.83.2.4.126.127.121.124.124.124.122.122.123.111.135.137.136.36.137.142.140.141.138.137.134.136.136.136.136.136.136.136.136.143.140.136.136.136.111.693.106.105.104.103.107.112.37.37.138.79.79.79.79.125.231.126.126.83.126.126.126.126.126.127.126. 176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 10V année, n° 2 Ville de Brossard \u2014 Town of Brossard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie (suite) \u2014 Cadastre Parish of Laprairie (.continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lots numéros Lots numbers Cadastre \t\tTaxes\t Taxes\tTaxes\tscolaires\t munie.\tscolaires\tprotest.\t \t\t\tTotal Munie.\tSchool\tProtest.\t taxes\ttaxes\tschool\t \t\ttaises\t \t$ 31.60\t\tÎ 31.50 \t211.05\t\t211.05 \t31.05\tS 12.71\t43.76 \t31.05\t\t31.05 \t31.05\t\t31.05 \t31.05\t\t31.05 S 359.79\t475.20\t\t834.99 \t161.09\t\t161.09 \t6.75\t\t6.75 369.77\t620.20\t\t889.97 \t520.20\t\t520.20 383.34\t478.80\t\t862.14 460.64\t96.75\t\t547.39 214.86\t230.40\t\t445.26 404.83\t24.28\t6.44\t435.55 471.92\t24.28\t6.44\t502.64 498.10\t24.28\t6.44\t528.82 479.43\t24.28\t6.44\t510.15 262.61\t211.50\t\t474.11 195.37\t31.95\t\t227.32 19.87\t17.10\t\t36.97 20.28\t17.10\t\t37.38 \t30.15\t\t30.15 \t18.90\t\t18.90 11.23\t10.95\t\t22.18 \t20.26\t\t20.25 94.04\t37.01\t\t131.05 \t60.23\t\t60.23 128.71\t53.01\t\t181.72 111.33\t48.90\t\t160.23 2,264.15\t198.33\t\t2,462.48 \t21.02\t\t21.02 172.81\t29.25\t\t202.06 172.81\t29.25\t\t202.06 405.81\t30.15\t\t435.96 405.81\t120.15\t\t525.96 406.81\t120.15\t\t525.96 405.81\t120.15\t\t525.96 408.08\t120.16\t\t528.23 403.88\t120.15\t\t524.03 \t54.39\t\t54.39 \t18.31\t\t18.31 \t15.94\t264.19\t280.13 342.46\t13.45\t268.83\t624.74 296.18\t18.31\t\t314.49 \t31.05\t17.72\t48.77 \t31.05\t17.72\t48.77 \t31.05\t17.72\t48.77 631.81\t1,304.50\t327.94\t2,164.25 196.92\t286.42\t110.25\t693.59 636.14\t172.19\t47.46\t755.79 2,730.36\t705.17\t112.14\t3,547.67 1,226.26\t174.42\t36.92\t1.436.59 521.13\t489.60\t105.80\t1,116.53 61.97\t112.60\t20.60\t185.07 311.08\t26.61\t301.27\t638.86 310.18\t26.61\t\t336.69 Gallaghan, John.Gauthier, Alfred.Gauthier, Bertrand.Gauthier, David.Gauthier, David & Alfred.Grink, Michael.Kennard, Rodman & Mary Kasperavicus, Balys.Kasperavicus, Balys.Kasperavicus, Balys.Kasperavicus.Balys.Lafrance, Robert.Lafrance.Robert.Lagarde, Gaétan Mme.Lagarde.Gaétan Mme.Lagarde, Gaétan Mme.Lagarde, Gaétan Mme.Lasnier, Claire Mlle.Martin, Alain.Mattachione, Dominico.Mattachione, Dominico.Mattachione, Bernardo.Mattachione, Bernardo.Provencher, Arthur Succ.Polger, Mrs.A.Ronci, Frank A.Ronci, Frank A.Ronci, Frank A.Ronci, Frank A.Ronci, Frank A.Ronci, Frank A.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Rousseau, Yvon.Scott, George.Popovi, Tomeslav.Morgan, Barry Gordon.Brown, Garry.Scardellato, Bruno.Aida Construction.Aida Construction.Aida Construction.Central Coin Automat Washing Machine.Central Coin Automat Washing Machine.H & M Construction.U & M Construction.H & M Construction.Substantial Dev.MTL.Substantial Dev.MTL.Kent, Maurice.Addison, Gilles.62.259.263.262.264.265.430.164.455 à 458.459.417.423.431.165.198.132.131.130.129.P.21.63.1131.1130.1126.1127.1.191.854 à 857, 882 à 885 P.886 à P.887.P.787.P.766.134.133.137.138.139.140.141.142.1106.167.197.86.44.153.148.271.270.269.1020, 1021 P.10- 232.234.83.121.121.121.121.121.139.140.36.36.139.139.139.140.126.P.122 126.126.126.126.99.83.79.79.79.79.672.120.79.79.P.79.79.79.P.79.P.79.126 .126.126.126.126.126.126.126.76.143.142.135.134.136.143.121.121.121.P.56.P.49.P.87.P.87.P.87.12____ 672.P.716 126.126. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 197S, Vol.10k, No.S 177 Ville de Brossard \u2014 Town of Brossard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie (suite) \u2014 Cadastre Parish of Laprairie (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lots numéros Lots numbers \t\t\tTaxes\t \tTaxes\tTaxes\tscolaires\t \tmunie.\tscolaires\tprotest.\t Cadastre\t\t\t\tTotal \tMunie.\tSchool\tProtest.\t \ttaxes\ttaxes\tschool\t \t\t\ttaxes\t 121.\t\t$ 17.27\t\t8 17.27 P.121.\t\t\t\t 121.\t\t261.91\t$1,427.70\t1,689.61 126.\t$ 165.47\t28.01\t6.89\t200.37 126.\t198.56\t16.81\t8.15\t223.52 126.\t198.56\t16.81\t8.15\t223.52 126.\t198.56\t16.81\t8.15\t223.52 126.\t238.28\t20.18\t4.44\t262.00 126.\t200.44\t16.81\t8.89\t226.17 126.\t200.48\t16.81\t8.89\t226.17 126____,.\t171.14\t22.41\t11.87\t205.42 126.\t182.35\t19.04\t10.15\t211.54 126.\t260.53\t21.67\t11.62\t293.72 126.\t202.31\t20.92\t11.07\t234.30 126.\t171.14\t22.41\t11.87\t205.42 126.\t200.48\t16.81\t8.89\t226.18 126.\t200.44\t16.81\t8.89\t226.14 126.\t200.44\t16.81\t8.89\t226.14 126.\t165.84\t28.39\t7.53\t201.76 126.\t200.44\t20.25\t\t220.69 126.\t\t\t97.72\t97.72 127.\t413.94\t212.40\t\t626.34 125.\t581.31\t25.78\t617.10\t1,224.19 125.\t564.13\t23.17\t612.83\t1,200.13 125.\t564.13\t23.17\t612.83\t1,200.13 125.\t564.13\t23.17\t612.83\t1,200.13 125.\t564.13\t23.17\t612.83\t1,200.13 125.\t582.64\t26.89\t618.95\t1,228.38 125.\t559.13\t25.02\t615.88\t1,200.03 125.\t559.13\t25.02\t615.88\t1.200.03 125.\t559.13\t25.02\t615.88\t1.200.03 125.\t558.14\t24.28\t614.17\t1,196.59 125.\t558.14\t24.28\t614.65\t1,197.07 125.\t558.14\t24.28\t614.65\t1,197.07 125.\t725 57\t456.60\t730.47\t1,912.64 125.\t540.91\t1449.99\t723.61\t1,714.51 125.\t540.92\t449.99\t723.61\t1.714.50 125.\t540.91\t449.99\t723.61\t1,714.51 125.\t540.92\t449.97\t723.61\t1,714.60 125.\t540.92\t449.99\t723.61\t1.714.52 125.\t542.63\t449.97\t723.61\t1,716.11 78.\t20.31\t14.56\t3.79\t38.66 78.\t21.91\t15.32\t\t37.23 79.\t94.72\t14.20\t3.70\t112.62 P.32.\t1,463.86\t1,162.33\t332.56\t2,958.75 P.46.\t458.51\t575.19\t152.27\t1.185.97 123.\t192.16\t18.55\t3.95\t214.66 125.\t\t\t\t 123.\t192.16\t18.55\t3.95\t214.66 125.\t\t\t\t 123.\t183.46\t17.77\t3.79\t205.02 125.\t\t\t\t 123.\t183.46\t17.77\t3.79\t205.02 125.\t\t\t\t 123.\t183.46\t17.77\t3.79\t205.02 125.\t\t\t\t 123.\t197.28\t19.36\t4.03\t220.67 125.\t\t\t\t 123 .\t211.60\t20.62\t4.28\t236.40 125.\t\t\t\t 123.\t196.28\t18.95\t3.95\t219.18 125.\t\t\t\t 81.\t\t25.40\t6.60\t31.00 81.\t\t25.40\t5.60\t31.00 80.\t\t\t\t Laval Industries.Laval Industries.Lareau, André.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc Les Habitations du St-Laurent Inc Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc Les Habitations du St-Laurent Inc.Les Habitations du St-Laurent Inc Les Habitations du St-Laurent Inc Les Habitations du St-Laurent Inc Galante, Luigi.Chandonnet, Normand.Les Placements Meilleurs.Les Placements Meilleurs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Steckler, H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Steckler.H.Mrs.Métropolitain Growth Corp.Métropolitain Growth Corp.Métropolitain Growth Corp.New Ore Holdings & Bestland.New Ore Holdings & Bestland.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Olympic Gardens Ltd.Placements Acadie Ltée.Placements Acadie Ltée.P.24, P.22, P.23.25.43.60.59.58.84.40.41.42.44.46.47.49.50.51.52.48.33.144.360.176.161.162.163.164.177.178.179.180.173.174.175.182.189.188.187.186.185.184.2.4.1136.134.145.135.146.137.148.138.149.139.150.127.138.128.139.129.140.66.68.38. 178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10f année, n° S Ville de Brossard \u2014 Town of Brossard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie (suite) \u2014 Cadastre Parish of Laprairie (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lots numéros Lots numbers \t\t\t\t\tTaxes\t\t \tTaxes\t\tTaxes\t\tscolaires\t\t \tmunie.\t\tScolaires\t\tprotest.\t\t Cadastre\t\t\t\t\t\t\tTotal \tMunie.\t\tSchool\t\tProtest.\t\t \ttaxes\t\ttaxes\t\tschool\t\t \t\t\t\t\ttaxes\t\t 136.\tS 422\t98\tS 146.41\t\t8 68.76\t\tÎ 628.14 136.\t203\t00\t23\t90\t6\t69\t233.49 142.\t228\t30\t19\t04\t6\t35\t252.69 138.\t303\t70\t3\t15\t67\t89\t374.74 139.\t\t\t\t\t\t\t P.258 à P.260\t406\t33\t133\t20\t79\t84\t619.37 83.\t\t\t13\t31\t472\t97\t486.28 83.\t\t\t170\t69\t94\t30\t264.99 83.\t\t\t16\t06\t94\t30\t110.36 81.\t103\t89\t14\t56\t4\t03\t122.48 82.\t\t\t\t\t\t\t 81.\t\t\t255\t10\t126\t47\t381.57 82.\t\t\t\t\t\t\t 82.\t\t\t\t\t\t\t 83.\t\t\t\t\t\t\t 83.\t\t\t931\t88\t472\t97\t1,404.85 126.\t405\t28\t24\t28\t\t\t429,66 127.\t418\t33\t25\t78\t\t\t444.11 126.\t\t\t\t\t\t\t 126.\t166\t55\t20\t60\t27\t88\t214.93 126.\t\t\t\t\t\t\t 126.\t198\t56\t16\t81\t8\t15\t223.52 126.\t198\t56\t16\tSI\t8\t15\t223.52 126.\t198\t56\t16\t81\t8\t16\t223.52 126.\t232\t11\t20\t18\t9\t80\t262.09 126.\t156\t10\t27\t27\t13\t24\t196.61 126.\t149\t00\t19\t42\t9\t43\t177.85 126.\t230\t85\t20\t18\t9\t80\t260.83 126.\t230\t75\t20\t18\t9\t80\t260.73 126.\t265\t48\t23\t17\t11\t26\t299.91 127.\t\t\t28\t39\t17\t58\t45.97 127.\t\t\t26\t51\t16\t35\t42.86 127.\t\t\t24\t28\t16\t09\t39.37 127.\t\t\t22\t79\t14\t03\t36.82 127.\t\t\t22\t41\t13\t85\t36.26 127.\t\t\t22\t41\t13\t85\t36.26 127.\t\t\t22\t41\t13\t85\t36.26 126.\t\t\t442\t98\t215\t06\t658.04 127.\t\t\t\t\t\t\t 126.\t199\t69\t17\t93\t11\t09\t228.71 126.\t199\t69\t17\t93\t11\t09\t228.71 126.\t199\t69\t17\t93\t11\t09\t228.71 126.\t239\t57\t21\t67\t13\t34\t274.58 P.126.\t\t\t126\t25\t79\t06\t205.31 135.\t\t\t23\t90\t12\t93\t36.83 136.\t\t\t\t\t\t\t 135.\t\t\t23\t90\t12\t93\t36.83 135.\t\t\t23\t90\t12\t93\t36.83 135.\t\t\t23\t90\t12\t93\t36.83 135.\t\t\t23\t90\t12.93\t\t36.83 135.\t\t\t27\t27\t14\t72\t41,99 126.\t170\t81\t31\t37\t15\t25\t217.43 126.\t170\t81\t31\t37\t15\t25\t217.43 126.\t170\t81\t31\t37\t15 25\t\t217.43 126.\t466\t56\t29\t88\t7\t82\t604.26 126.\t406\t37\t28\t39\t106\t75\t640.61 126.\t174\t36\t28\t39\t13\t79\t216.54 126.\t174\t36\t28\t39\t13\t79\t216.64 126.\t196\t37\t1\t10\t14\t13\t211.60 640.61 126.\t406\t37\t28.39\t\t105.76\t\t 129.\t\t\t14\t19\t\t\t14.19 120.40 126.16 129.\t\t\t120 40\t\t\t\t 130.131.\t\t\t126\t16\t\t\t \t\t\t140 77\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t140.77 Presto Dev.Corp.Presto Dev.Corp.Presto Dev.Corp.Presto Dev.Corp.Roma Realties lue.System Homemakers., System Homemakers____ System Homemakers.System Homemakers.System Homemakers.System Homemakers.T.S.D.Construction Ltée T.S.D.Construction Ltée T.S.D.Construction Ltée Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Vienna Construction Inc.Windsor Holdings Inc.Windsor Holdings Inc.Windsor Holdings Inc.Windsor Holdings Inc.Windsor Holdings Inc____ Windsor Holdings Inc____ C & C Construction.C & C Construction.C & C Construction.Gusto.Angelo.Tridon Holdings.Tridon Holdings.Tridon Holdings.Tridon Holdings.Tridon Holdings.Bédard, François.Blanchet, Cécile Mme.Brûlé, André.David, Claude.460.490.204.207.364.82.76.75.171.53.172.64.65.77.78 à 82.125.323.126.P.210.P.211 207.63.62.61.89.91.92.93.85.87.319.318.317.316.315.314.313.146.362.98.99.100.101.195.648.194.193.192.191.189.247.248.249.251.259.261.260.266.258.268.259, 260.69, 70.71.73.P.74.16.P.17.20.21. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 197S, Vol.10i, No.S 179 Ville de Brossard \u2014 Town of Brossard (Commission scolaire de Brossard) \u2014 (Brossard School Board) Cadastre paroisse de Laprairie (suite) \u2014 Cadastre Parish of Laprairie (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lots numéros Lota numbers Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxes scolaires School taxes Taxes scolaires protest.Protest, school taxes Delisle.Léo.Dubois, Guy.Dubois.Roger.Dubuc, Bernard.Fillipone, Letisia.Fillipone.Letisia.Fillipone, Letisia.Fillipone, Maria Paola.Claude.Roland.Gosselin, Jean-Claude.Haineault, Lucie.Haineault, Lucie.Haineault, Paul A.Haineault, Paul A.Haineault, Paul A.Haineault, Paul A.Halo, Succ.Jules.Jalbert, Lucien.Jameson, Albert.Laberge.Joseph.Lalonde, Charles.Lalonde, Armand.Leblanc.Bernard.Marquis.Kobert.Morin.Claude.Ouellette, Rhéaume.Parent, Lucien.Poliquin, Y.& S.M.Demers Poudrier, Claude.Prince.Rosaire.Richard.Claude.Robitaille, Cécile.Rousseau, Marc.St-Laurent, André.Terrault, Claude.Terrault, Claude.Théorét.Jean.Thérien.Georges.Trudeau.D.Daigneault Vandal.Thomas.Vivier, Eva.181, 182.392, P.393.P.142, 143.P.221, 222.P.58, P.59.23, 24, 25, 26.1A4.1(15 200.201.202.203 184.185.129.316.218.219.P.220.52 à 54.403 à 405.446 à 448.406 à 408.409, 410.441, 442.382, 383.484.280, 281.580 à 582.31 à 33.4 à 6.98, 99.274, 275.383, 384.292.293.194 à 196.172, P.173.17, 18.241 à 243.P.88.P.89.P.114, P.115.383, 384.292, 293.583, 584.108.109.472 à 474.417 à 419.265.266.89.90.122 à 124.341 à 343.305, 306.176, 177.437, P.438.241, 242.P.129.130.P.202.203.173 à 175.131.133.128.129.128.128.129 129.128.129.133.129.130.130.130.130.130., 133.133.133.129.128.129.132.131.130.131.129 .128 .133.133.128.129.130.131.129.131 129.133.131 .132.132.131.129.130 .130.131.130 133.133 .78.48 70.I 1 242.97 110.51 28.17 12.04 14.19 13.55 164.24 107.40 16.47 26.66 31.51 9.46 286.60 12.71 177.81 121.91 73.96 49.13 153.42 131.15 112.45 40.09 334.88 146.08 142.87 277.55 419.41 63.66 279.83 86.22 213.63 16.58 135.73 107.84 136.35 102.77 27.76 129.68 121.49 La Commission municipale de Québec, par décision en date du 15 décembre 1971, a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles qui sont consécutifs et qui appartiennent au même propriétaire, le tout conformément aux dispositions des articles 416 et suivants de la Loi de l'Instruction publique (Statuts Refondus de Québec, 1964, chapitre 235).The Québec Municipal Commission by a decision dated December 15th, 1971, has authorized an abridged enumeration of the immoveables who arc consecutive and belonging to the same owner, under the authority of the article 416 and subsequent of the Education Act (Revised Statutes of the Province of Québec, 1964, chapter 235). 180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n° 2 Municipalité de St-Constant \u2014 Cadastre Paroisse de St-Constant Municipality of St.Constant \u2014 Cadastre Parish of St.Constant Nom du propriétaire Name of proprietor Lots Nos Lots Nos.Cadastre Taxes\tInt.\t\tTaxes\t\tInt.\t\t munie.\tmunie.\t\tscol.\t\tscol.\t\t \t\t\t\t\t\tTotal\t Munie.\tMunie.\t\tSchool\t\tSchool\t\t taxes\tint.\t\ttaxes\t\tint.\t\t S 29.25\t3 7\t02\t\t\t\t3 36\t27 42.75\t10\t26\t\t\t\t63\t01 98.40\t23\t62\t$ 634\t83\t8 76.85\t833\t70 \t\t\t663\t13\t65.05\t728\t18 3.60\t\t86\t39\t60\t5.35\t49\t41 4.95\t1\t19\t48\t72\t6.45\t61\t31 4.65\t1\t12\t46\t69\t6.20\t58\t66 7.84\t2\t28\t19\t24\t2.30\t31\t66 2.25\t\t54\t\t\t\t2\t79 \t\t\t51\t01\t7.62\t58\t63 \t\t\t51\t01\t7.62\t58\t63 2.55\t\t61\t53\t79\t8.00\t64\t96 13.99\t4\t00\t60\t79\t6.50\t75\t28 5.53\t1\t55\t\t\t\t7\t08 5.54\t1\t66\t\t\t\t7\tid 3.15\t\t76\t\t\t\t3\t91 8.10\t2\t30\t22\t36\t2.65\t35\t\u2022II .62\t\t17\t\t\t\t\t79 .31\t\t09\t5\t49\t.86\t6\t73 .31\t\t09\t6\t49\t.84\t6\t73 .31\t\t09\t1\t02\t.12\t1\t64 .62\t\t17\t2\t03\t.24\t3\t06 .62\t\t17\t2\t03\t.24\t3\tor, .62\t\t17\t2\t03\t.24\t3\t06 .62\t\t17\t2\t03\t.24\t3\t06 .62\t\t17\t1\t87\t.22\t2\t88 9.84\t2\t76\t32\t40\t3.90\t48\t90 27,97\t6\t71\t362\t44\t49.20\t446\t32 49,05\t11\t77\t39\t49\t5.20\t105\t51 143.68\t34\t48\t136\t33\t10.90\t325\t39 143.25\t34\t38\t\t\t\t177\t63 67.50\t16\t20\t25\t32\t3.05\t112\t07 123.25\t29\t58\t\t\t\t152\t83 \t\t\t398\t06\t44.80\t442\t86 \t\t\t202\t47\t24.00\t226\t47 57.00\t13\t68\t120\t49\t17.00\t208\t17 52.50\t\t\t\t\t\t52\t60 109.95\t44\t05\t\t\t\t154\t00 207.15\t81\t92\t\t\t\t289\t07 107.35\t\t\t\t\t\t107\t35 79.40\t19\t06\t77\t39\t6.29\t182\t05 415.25\t99\t66\t110\t19\t8.80\t6.33\t90 100.50\t24\t12\t\t\t\t124\t62 148.35\t35\t60\t223\t37\t30.65\t437\t97 74.58\t20\t99\t255\t96\t21.45\t372\t98 30.05\t7\t21\t\t\t\t37\t26 73.45\t17\t63\t129\t37\t10.35\t230\t80 57.65\t13\t81\t148\t84\t17.80\t238\t00 41.01\t10\t78\t94\t24\t7.55\t153\t68 4.39\t1\t23\t\t\t\t5\t62 4.24\t1\t20\t\t\t\t5\t44 5.44\t1\t50\t\t\t\t6\t94 3.94\t1\t13\t\t\t\t5\t07 3.94\t1\t13\t\t\t\t5\t07 3.94\t1\t13\t\t\t\t5\t07 4.09\t1\t16\t\t\t\t5\t25 4.09\t1\t16\t\t\t\t5\t26 4.54\t1\t27\t\t\t\t5\t81 4.54\t1\t27\t\t\t\t5\t81 4.54\t1\t28\t\t\t\t6\t82 4.54\t1\t28\t\t\t\t6\t82 6.89\t1\t60\t\t\t\t7\t19 5.89\t1\t60\t\t\t\t7\t49 4.09\t1\t16\t\t\t\t6\t25 4.09\t1\t16\t\t\t\t5\t26 4.09\t1\t16\t\t\t\t5\t26 4.09\t1\t16\t\t\t\t5\t26 4.09\t1\t16\t\t\t\t6\t26 Nicholson, John.Nicholson, John.Leigh Investment.Leigh Investment.Lamler, Nicole.Lamler, Nicole.Lamler, Nicole.Verrucci, Gil.Nicholson, John.Patulli, Aurèle.Patulli, Aurèle.Clark, Daisy.Leroux, Claude.Poirier, Gaston.Poirier, Gaston.Tille, James.Stanford Inv.Ltd.Johnston.William.Warner.Elisabeth.McCord.Robert.Taylor.Auster.Dempster, Annie Mme.Wilsh, Andrew A.The Berdford Stove.Currie, Edwin.Bella Vista Inv.Heym, Adolf.Doran, Ormand.Lanctot, Philias.Sicotte, Marie R.Doucet, Gilles.Lanctot, Philias.Albert, Armand.Demers, Lucien.Guidy, Henri.Peladeau, Raymond.Lockhart, Mme Hilda.Lockhart, Mme Hilda.Lockhart, Mme Hilda.Lockhart, Mme Hilda.Lefebvre Archambault, Mme Diane.Carr, Georges.Montfils, G.Mme Raymonde.Parity Inv.Cauchon, Normand.Biais, Léonide.Dickson, Georges.Markotanyos Zakarzewski, J.P.Guyon, Denis & Drolet, Mme Lise.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerb&ok, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback.Edward.Auerback.Edward.Auerback, Edward.Auerback.Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback.Edward.Auerback, Edward.7.8.9.60.162.163.201.241.264.265.276.9, 10, 11.264, 265.297.299.353.378.429, 430.437,438.439.521, 522.P.1____ P.1-4.P.1-20.1-33.1-33____ 1-45.1-42____ P.1-89.P.1-126.P.-1-172.15.16.17.1-115.21 P.8____ 13.12.4.11____ 18____ 2.4.5 .13.14.16.25.4.5.6.7.in.11.27.28.20.31.32.P.20.P.20.P.100.P.101.119.119.119.119.119.119.119____ 119.119.119.119.119.127____ 129____ 129.129____ 129.129.129.129____ 129____ 129.150.150.150.150____ 150____ 150.150.150.150.150.150.150.150.150.150 .P.151.153.P.167.174.176.176.176.P.234.P.234.P.234.P.234.P.234.P.234.P.234.P.234.P.234.235.235.235.235.235.235____ 235.235.236.235.235. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 181 Municipalité de St-Constant \u2014 Cadastre Paroisse de St-Constant (suite) Municipality of St.Constant \u2014 Cadastre Parish of St.Constant (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Auerback, Edward- Auerback.Edward- Auerback, Edward____ Auerback, Edward- Auerback, Edward____ Auerback, Edward.Auerback, Edward.Auerback, Edward____ L'abbé, Reginald.L'abbé, Reginald.Roufosse, Albert.Roufosse, Albert.Roufosse, Albert.Roufosse, Albert.Winchester Dev.Fisleigh, Harold F.Quirion, Renald Levko, Mme E.Velmakos.Andreas.Schodra.Julius.Schodra, Julius.Caron, Maurice.Caron.Maurice.Caron, Maurice.Mantinho.Rufael.Gagné.Valier.Gagné.Valier.Gagné.Valier.Gagné, Valier.Gagné.Valier.Sicottc, Robert.Lefebvre.Héliodore.Cyr.Aurèle.Schatika, Hans.Turcotte, Victor.Bannon, Gilles.Zeiïiel, Isaac.Deniers, Régent .tioclerc, Jacqueline.Brais.Ls-Paul.Lockhart, Hilda.Lockhart, Hilda.Leigh Investment Ltd.Leigh Investment Ltd.Leigh Investment Ltd.Leigh Investment Ltd.Leigh Investment Ltd.Morin, J.Morin, Roger.Nadeau, Doris.Lota Nos Lots Nos.33.34.35.36.37.38.39.40.11.12.106 107 108 114 177 199 232 281 286 82.83.84.134 169 170 171 172 173 25.53.69.85.54.1-115.15.16, 17 131 24.81.\tTaxes\tInt.\tTaxes\tInt.\t \tmunie.\tmunie.\tscol.\tscol.\t Cadastre\t\t\t\t\tTotal \tMunie.\tMunie.\tSchool\tSchool\t \ttaxes\tint.\ttaxes\tint.\t 235.\tt 4.09\t$ 1.16\t\t\tS 5.26 235.\t4.09\t1.16\t\t\t5.25 235.\t4.09\t1.16\t\t\t5.25 235.\t4.09\t1.16\t\t\t6.25 235.\t5.29\t1.45\t\t\t6.74 235.\t4.09\t1.16\t\t\t5.25 235.\t4.00\t1.16\t\t\t5.16 235.\t4.09\t1.16\t\t\t5.25 249.\t48.60\t11.66\t$ 59.58\tt 8.55\t128.39 249\t47.10\t11.30\t49.46\t7.30\t115.16 249.\t17.40\t4.18\t32.58\t4.55\t68.71 249.\t14.10\t3.38\t31.26\t4.45\t53.19 249.\t14.10\t3.38\t31.26\t4.45\t53.19 249.\t29.55\t7.09\t33.26\t4.60\t74.60 P.123\t225.90\t54.22\t\t\t280.12 P.123 & 255\t70.37\t17.55\t\t\t87.92 256.\t86.40\t24.04\t1.96\t.15\t112.54 256.\t25.85\t6.20\t\t\t32.05 256\t58.20\t15.02\t124.20\t19.35\t216.77 256.\t86.40\t24.04\t26.33\t3.15\t139.92 256.\t86.40\t24.04\t26.33\t3.15\t139.92 258.\t91.77\t25.73\t\t\t117.50 258.\t91.77\t25.73\t\t\t117.50 258.\t91.79\t25.74\t\t\t117.53 268.\t13.10\t3.14\t\t\t16.24 258.\t13.10\t3.14\t9.28\t.90\t26.42 258.\t13.10\t3.14\t17.33\t2.20\t35.77 258.\t13.10\t3.14\t17.33\t2.20\t35.77 258.\t13.10\t3.14\t17.33\t2.20\t35.77 258.\t13.10\t3.14\t17.33\t2.20\t35.77 259 .\t164.45\t39.47\t\t\t203.92 259.\t20.75\t4.98\t\t\t25.73 259.\t12.95\t3.11\t\t\t16.06 259.\t16.70\t4.01\t\t\t20.71 261.\t28.05\t6.73\t\t\t34.78 P.271.,\t51.10\t12.26\t\t\t63.36 305 & 306\t78.00\t18.72\t1.937.52\t231.55\t2,265.70 P.311.\t\t\t135.85\t10.85\t146.70 P.321.\t22.50\t5.40\t\t\t27.90 P.395\t34.00\t9.68\t\t\t43.68 150.\t112.87\t26.94\t\t\t139.21 150.\t55.80\t13.39\t\t\t69.19 96.\t\t\t964.84\t94.65\t1,059.49 97.\t\t\t611.33\t60.00\t671.33 97.\t\t\t304.75\t29.90\t334.65 103.\t\t\t1,415.51\t154.75\t1,570.26 303.\t\t\t469.32\t46.05\t515.37 247.\t52.01\t16.64\t\t\t68.65 247.\t96.56\t30.90\t\t\t127.46 258.\t4.41\t1.41\t\t\t5.82 Municipalité de Notre-Dame \u2014 Cadastre paroisse de Laprairie Municipality of Notre-Dame \u2014 Cadastre Parish of Laprairie \tLots\t\tTaxes\tTaxes\t Nom du propriétaire\tNos\t\tmunie.\tscol.\t \t\tCadastre\t\t\tTotal Name of proprietor\tLota\t\tMunie.\tSchool\t 1\tNos.\t\ttaxes\ttaxes\t \t559, 560.\t129.\t$148.26 241.41 288.90\t\t% 148.26 241.41 288.90 \t561.424 à 426.\t129.133.\t\t\t 182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10i- année, n° 2 Municipalité de Notre-Dame \u2014 Cadastre paroisse de Laprairie (euiic) Municipality of Notre-Dame \u2014 Cadastre Parish of Laprairie (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lots Nos Lots Nos.Cadastre Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Brûlé.André.Bredich.Mrs.Edwin.Burt, Edward.Charleboix, André.Chartier, Armand.Dechamplain, André.Dubois, Roger.Gosselin.Jean-Claude.Haineault.Dame Lucie.Joubert.Jacques.Kendrick, Victor.Laberge.Succession J.Lalonde.Charles.Leblanc, Bernard.Lalonde.Armand.Morin.Claude.Ouellette.Rhéaume.Poliquin, Y.& Poudrier, C Parent, Lucien.Raymond, Maurice.Rousseau, Marc.Terreault, Claude.73.P.74.16.P.17.343.P.344.600.601.241.242.426, 427.238! 239, 295, 369 à 363!! P.142, 143.P.221.222.52 il 54.403 à 405.446 à 448.245.246.173.174.4 a 6.31 à 33.98.99.274, 275.169, 171, 194, 196.383, 384.292, 293.17, 18.241 à 243.583, 684.88, 89.114, 115.411, 412.89, 90.2651 267.305, 306.176.177.130 131 129 129 128 129 131 130 128 129 129 130 131 128 129 128, 132 131 129 130 131 133 133 12S 128 129 130 132 131 129 130 $137.16 151.03 311.81 92.18 69.55 430.26 170.15 46.75 189.64 61.66 137.21 93.82 130.59 295.81 192.46 206.06 118.56 225.07 139.35 152.17 147.20 316.01 $ 137.16 151.03 311.81 92.18 69.55 430.26 170.15 46.75 189.64 61.66 137.21 93.82 130.59 295.81 192.46 \u202221 Hi llrt 118.56 225.07 139.35 162.17 147.20 316.01 Municipalité de 8t-Philippe -Municipality of St.Philippe - Cadastre paroisse de St-Philippe - Cadastre Parish of St.Philippe Bizzuti, Francesco.Bourdon, Maria.Chalipa.Michael.Chowdury, M.S.A.Cloppenburg, Heinz.Cloppenburg, Heinz.Cloppenburg, Heinz.Czarnucha, Alexander.Darzins, A.Luis.Demeter, Helen.Di Manibio, Franco.Domencie.Mazzocia.Donato, Emmanuel.Dremov, Alexander.Elek.Julia.Enedy.John.Felika, Frank.Forte.Emmanuelle.Graw, Emmanuel.Wilson, Lucille.Hammerschmidt, Gerhard Hammerschmidt, Gerhard Hammerschmidt, Gerhard Hammerschmidt, Gerhard Hammerschmidt, Gerhard Horvath, Mario.Horvath, Mario.Kaminiski, Eva.Lange, Walter.Lange, Walter.Lange.Walter .66.\t8 2.00\t$ 16.17\t3 18.17 66.\t5.45\t30.73\t36.18 65.\t1.63\t16.17\t17.80 68.\t2.13\t30.73\t32.86 269.\t\t30.73\t30.73 269.\t\t30.73\t30.73 269.\t\t30.73\t30.73 88.\t1.60\t18.17\t17.67 66.\t2.30\t30.73\t33.03 66.\t\t16.17\t16.17 66.\t2.00\t18.17\t18.17 66.\t2.25\t30.73\t32.98 66.\t2.00\t16.17\t18.17 66.\t\t16.17\t16.17 66.\t2.13\t16.17\t18.30 65.\t2.00\t16.17\t18.17 270.\t3.42\t30.73\t34.15 \t\t16.17\t16.17 66.\t4.20\t30.73\t34.93 270.'.\t\t30.73\t30.73 269.\t\t30.73\t30.73 269.\t\t30.73\t30.73 269.\t\t30.73\t30.73 \t\t30.73\t30.73 269.\t\t3(1 t:i\t30.73 \t2.50\t30.73\t33.23 270.\t2.50\t30.73\t33.23 66.\t\t30.73\t30.73 270.\t6.00\t30.73\t35.73 \t6.00\t30.73\t35.73 270.\t6.00\t30.73\t36.73 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 183 Municipalité de St-Philippe \u2014 Cadastre paroisse de St-Philippe (euite) Municipality of St.Philippe \u2014 Cadastre Parish of St.Philippe (continued) Nom du propriétaire Name of proprietor Lange, Walter.Lange, Walter.Larmont, Terence John.Lemezyk, William.Lucenet, Pierre.Luciw, Oresta.t.Ludwiczak, Kazimiera.Macurek, Stanislaw.Martin, Hilda Anny.Martin.Hilda Anny .Meot, Angèle.Meot, Angèle.Mongiello, Frank.Mytka, Michel.Pellissard.Bernard.Pellissard, Bernard.Pineaud, Renée.Pochyla, Adam.Pochyla, Adam.Sanginesi, Antonio.Semenenko, Michael.Silvestri, Emidio.Slobodian, Peter.Sydor, G.Szczygiel, André.Szoke, Kalman.Troube.Michelle____ St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp Fantini, Donato.Frank Néglia.Orosz Miklos.Stanislaw Pietrieczek.Alfred SakaitiS.Joseph Barna.William Csabay.Michel Foorey.Nikolaos Zafîratos.Kazamierz Owsial.Kulkys Kazys.Rocco Rocanelli.Bill Shymchuck.St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp St.Lawrence Plaza Corp Lots Nos Lota Nos.328.329.195.409.460.186.286.174.340.273 214.215.461 101 291.292 467.323.324 191 223 65.451 376 99.218 376 365 237 379 181 308 102 6.411 17.430 12.511 309 284 320 337 15.110 384 414 212.250.288.488 112 113 246.247.Cadastre 270 270 269 65.272 65.272 272 269 269 272 272 65.65.272 272 272 65.65.65.65.65.65.65.270 65.272 269 270 270 65.65.269 270 272 65.65.270 65.272 65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.269 269 269 269 Taxes munie.Munie, taxes 5.00 5.00 1.50 3.80 2.50 2.85 2 SB .95 .96 1.13 2.00 2.00 3.91 2.40 2.40 3.67 2.00 2.00 2.95 2.00 2.00 3.80 3.80 3.80 3.30 2.00 3.80 5.35 3.95 2.15 2.12 5.00 2.50 9.60 9.86 6.20 3.13 2.00 2.00 2.00 2.00 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 Taxes scol.School taxes S 30.73 30.73 30.73 16.17 30.73 16.17 30.73 30.73 30.73 30 73 30.73 30.73 16.17 16.17 30.73 30.73 30.73 30.73 30.73 16.17 16.17 30.73 16.17 16.17 30.73 16.17 30.73 30.73 30.73 30.73 12.69 23.41 12.65 12.69 16.17 16.17 16.17 16.17 30.73 30.73 30.73 30.73 30.73 30.73 30.73 30.73 184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Municipalité de St-Mathieu \u2014 Cadastre Paroisse de St-Philippe Municipality of St.Mathieu \u2014 Cadastre Parish of St.Philippe Nom du propriétaire Name of proprietor Leigh Investment.Leigh Investment.Leigh Investment.Leigh Investment.Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Seiber Development Lots Nos Lots Nos.Cadastre 335.336.332, 334.336.336.326.325.320.319.318.284, 285____ 315.316.315,207.208 315.314.311.312, 313____ Taxes munie.Munie, taxes Int.munie.Munie, int.Taxes\tInt.\t scol.\tscol.\tTotal School\tSchool\t taxes\tint.\t S3,818.53\tS 49.08\tS 3.867.61 1,360.54\t17.88\t1.378.42 1,275.06\t16.23\t1,291.29 430.76\t5.79\t436.55 2,161.69\t16.44\t2,178.13 2,156.28\t27.78\t2,184.06 625.56\t\t625.56 2.234.73\t19.08\t2.253.81 2,631.67\t22.50\t2,654.17 803.12\t11.08\t874.20 1,752.31\t14.80\t1,767.11 1,529.70\t13.08\t1.542.78 1,095.03\t9.60\t1,104.53 905.75\t11.40\t917.15 863.92\t7.50\t871.42 552.37\t4.82\t657.19 880.70\t11.61\t892.31 Municipalité de St-Mathieu \u2014 Cadastre Paroisse de St-Constant Municipality of St.Mathieu \u2014 Cadastre Parish of St.Constant Leigh Investment Leigh Investment Leigh Investment Leigh Investment 30, 31, 32.33.38.93.32, 34.$264.36\t$ 7.80\t$2,850.94\t$ 36.60 \t\t2,139.61\t27.51 \t\t1,464.20\t18.90 \t\t94.19\t1.44 $ 3,159.70 2,167.12 1,483.10 95.63 Donné à La Prairie, ce 7e jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44002-2-2-o Gérard Péladeau.Given at La Prairie, this 7th day of January, 1972.Gérard Péladeau, 44002-2-2-o Secretary-Treasurer.Municipalité du comté de Joliette Avis public est par les présentes donné par le soussigné L.-M.Hétu, secrétaire-trésorier de la corporation du conseil de comté de Joliette, que les immeubles ci-après montionnés seront vendus à l'enchère publique, au premier étage du Bureau d'Enregistrement, 591, rue Notre-Dame, en la cité de Joliette, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MARS 1972, à DIX heures de l'avant-midi, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont assujettis et des frais encourus, savoir: Municipality of the County of Joliette Public notice is hereby given by the undersigned L.-M.Hétu, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Joliette.that the hereinafter mentioned immoveables shall be sold at public auction, on the first floor of the Registry Office.591 Notre-Dame Street, in the city of Joliette, THURSDAY, the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, in default of payment of the taxes to which they are subjected, and the cost incurred, namely: Corporation municipale de St-Alphonse Municipal Corporation Noma Names Descriptions Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total R.Jomphe & O.Cormier.4B-14, 2e rang-2nd range, Aug.de Kildare____ $106.46 $106.46 Lagana, Antonio.4B-64.2e rang-2nd range, Aug.de Kildare.$ 12.44 16.89 29 33 Farber.& Reid.6A-27, 2e rang-2nd range, Aug.de Kildare____ 94.96 149.98 244 94 Creswell Joh.n.5A-28, 2e rang-2nd range, Aug.de Kildare- 64.76 187.95 242Ï71 Parent Emmanuel.6A-50, 2e rang-2nd range, Aug.de Kildare- 22.68 132.07 164.75 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.104, No.S 185 Corporation municipale de St-Alphonse Municipal Corporation (suite) \u2014 (continued) Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes Carmen PoliqUin-D aigle.Mayer, Jacques.Corbeil, Fernand.Aubry, Adrien.Daigneault, Fernand.Doyon, Jean-Jacques.Dupuis, Philippe.Fortier Stanislas.Gibeau, Claude.Gibeau, Paulue.Heuga, Jean-Louis.Marre, Raymond.Poliquin,, Jean-Jacques.Pouliot, Jean-Paul.Rioux, Roger.SénécaUGillette-H.Trahan, Marcel.Perron, Normand.Partie du lot 24A du premier rang du Canton Cathcart, ayant 100 pieds en front vers le nord-est sur un chemin privé, 100 pieds vers le sud-est, et environ 256 pieds sur chacun des côtés; et borné comme suit: vers le nord-est audit chemin privé, vers le sud-ouest au chemin privé dit chemin des Infirmes, au nord-ouest par le terrain de Josaphat Loyer ou représentants, et du côté sud-est par Dame Simone Mercure Asselin ou représentants.Lemay, Marcel.Un terrain faisant partie du lot 21A du premier rang du Canton Cathcart en la paroisse de St-Alphonse, mesurant 200 pieds de largeur sur toute la profondeur qu'il y a du Lac Pierre au passage commun ci-après mentionné et étant borné à l'est par autre partie du 21A étant un passage commun, à l'ouest par le Lac Pierre, au sud par autre partie dudit lot 21A appartenant à Réal Boland, et au nord par autre partie dudit lot 21A appartenant à Conrad Lemay ou représentants.Lagacé, Gilles.Description: Un terrain faisant partie du lot 14B du demi rang des Augmentations de Kildare en la paroisse de St-Alphonse ayant 120 pieds à un bout ou il est borné au vendeur, 145 pieds au bout opposé où il est borné à autre partie dudit lot au vendeur, 150 pieds d'un côté où il est borné au vendeur et 150 pieds de l'autre côté où il est borné à un chemin privé de passage.Micheline, G.Jolicoeur.Un terrain faisant partie du lot 24C du premier rang du Canton Cathcart en la paroisse de St-Alphonse, mesurant 90' de largeur vers le sud-ouest et le nord-est, et 125 vers le nord-ouest et le sud-est et borné comme suit: au sud-ouest par un chemin privé, au nord-ouest et nord-est par le terrain de Josaphat Loyer ou représentants, au sud-est par le terrain de David Biais ou représentants .Boivin, J.-E.Un terrain faisant partie du lot 27 du 3ième rang du Canton Cathcart de figure irrégulière, mesurant 200' sur le chemin public qui le borne en front et 110' de largeur sur la rivière l'Assomption qui le borne en profondeur sur une profondeur de 300' dans la ligne ouest le long du terrain d'Alphonse Duplessis, la ligne est étant une ligne brisée mesurant 364' de profondeur le long d'un chemin mitoyen partant du chemin public en allant à la rivière l'Assomption.20-372, 373, 3e rang-3rd range, Cathcart.21-216, 240, 329, 3e rang-3rd range Cathcart .20-340, 3e rang-3rd range, Cathcart.20-369, 370, 3e rang-3rd range, Cathcart.20-335, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-56, 57, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-78, 79; 19-88, 89, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-104, 3e rang-3rd range, Cathcart.21-114, 3e rang-3rd range, Cathcart.21-224, 3e rang-3rd range, Cathcart.21-314, 316; 21-442, 444, 3e rang-3rd range, Cat,hcart.19-205, 206, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-248, 249, 3e rang-3rd range, Cathcart.20-482, 483, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-159, 3e rang-3rdrange, Cathcart.20-238, 3e rang-3rd range, Cathcart.19-153, 3e rang-3rd range, Cathcart.s\t73.44 $\t73.44 18.84\t24.69\t43.43 \t146.78\t146.78 65.60\t98.04\t163.64 112.92\t167.13\t280.05 112.92\t228.52\t341.44 95.64\t195.41\t291.05 12.44\t16.89\t29.33 23.66\t32.80\t56.36 23.66\t32.80\t56.36 23.66\t24.59\t48.15 53.88\t114.67\t168.55 43.44\t35.72\t79.16 53.20\t83.44\t136.64 32.32\t50.17\t82.49 23.56\t24.60\t48.16 '53.88\t90.03\t143.91 12.44\t16.89\t29.33 Part of lot 24A of first Range, township of Cathcart, measuring 100 feet in front towards the northeast on a private road, 100 feet towards the southeast and about 256 feet on each side and bounded towards the northeast at the said private road, towards the southwest by a private road named \"Chemin des Infirmes\", towards northwest by the land of Josaphat Loyer or representatives and towards the southeast by the land of Mrs Simone Mercure-Asselin or representatives.12.44 8.20 20.64 A piece of land being a part of lot 21A in the first Range of the township of Cathcart, in the parish of St-Alphonse, measuring 200 feet in width by the whole depth from \"Lac Pierre\" to a common passage hereafter mentioned and being bounded on east by other part of 21 A, being a common passage, in the west by Lac Pierre, on south by other part of 21A belonging to Real Boland and on north by another part of 21A belonging to Conrad Lemay or representatives.12.44 16.89 29.33 A lot of land being a part of lot 14B of half Range of Augmentations .de Kildare, in the parish of St-Alphonse, measuring 120' on one end bounded by the vendor, 145' on the other end bounded by the vendor, 150' on one side bounded by the vendor and 150' on the other side bounded by a private road.12.44 16.89 29.33 A lot of land being a part of lot 24C of the first Range of the township of Cathcart, in the parish of St-Alphonse measuring 90' in width on the southwest and the northeast and 125' on the northwest and southeast and bounded on the southwest by a private road, on the northwest and northeast by the land of Josaphat Loyer or representatives, on the southeast by the land of David Biais or representatives.24.00 165.17 189.17 A lot of land being a part of lot 27 of the third Range of the township of Cathcart of irregular figure, measuring 200' on the public road that bounds it in front and 110' in width on l'Assomption River that bounds it on depth by a depth of 300' in the west line alongside the land of Alphonse Duplessis, the east line being a broken line measuring 364' in depth alongside a dividing road starting from the public road to L'Assomption River. 186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, m* année, n° ê Corporation municipale St-Jean-derMatha Municipal Corporation Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes 376-18.19, St-Jean-de-Matha.375-90.St-Jean-de-Matha.375-14, 15, 16, St-Jean-de-Matha Justin, Ciale.L.Boucher Howard.Jean, Panta.Beaupré, Elzéar.Un terrain connu et désigné comme faisant partie du lot cinq cent soixante-huit (P.568) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Matha, division d'enregistrement de Joliette, borné en front par le lac Noir, de tous les autres côtés par parties 568, la borne arrière étant le chemin public, une des bornes latérales étant la propriété de David Lépine ou représentants, et l'autre borne étant la propriété de L.-P.Marcotte ou représentants.Mario, Dangubic.Un terrain connu et désigné comme faisant partie du lot cent un (ptie 101) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St^Jean-de-Matha pour la partie de Brandon, situé à environ 660 pieds de la ligne de division du lot 102 dudit cadastre et à environ 600 pieds du lue.mesure anglaise, plus ou moins, et borné comme suit: au nord ouest par un chemin privé étant une partie de 101, au nord-est par partie 101 étant le No 101-126 sur un plan non déposé, au sud-est par partie 101, appartenant au vendeur étant les lots 101-171 et 101-172 sur le même plan et au sud-ouest par partie 101 étant le lot 101-123 sur le même plan.S 12.42 % 12.42 .$ 4.83 6.93 11.76 .16.63 16.63 75.78 316.66 392.44 A part of lot known and designated as being a part of lot five hundred and sixty-eight on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, Joliette Registry Office, bounded in front by the \"Lac Noir\" and on all the other sides by parts of 568, an in rear by a public road, on one side by the land of David Lépine or representatives and ou the other side by the land belonging to L.-P.Marcotte or representatives.14.18 14.18 A part of land known and designated as being a part of lot hundred and one (p.101) on the officiel plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, situated at about 660 feet from the division line of the lot 102 said cadastre and at about 600 feet from the lake, English measure, more or less, bounded as follows by the northwest a private road part of 101, by the northeast by lot 101-126 on an non-official plan, by southeast by part 101 being lots 101-171 and 101-172 on the same plan and by the southwest by part 101 being 101-123 on the same plan.Lacombe, Marcel.Un emplacement situé en la paroisse de St-Jean-de-Matha, Canton Brandon, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro vingt (p.20) du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Matha.partie Brandon, pris au sud de l'emplacement de André Dallaire, pris également au sud-ouest de la route, contenant 138 pieds de largeur le long de la route et 120 pieds en arrière sur 100 pieds de profondeur et borné en front par la route, en profondeur au sud-ouest par Orner Laramé, au nord-ouest par Dallaire, au sud-est par le terrain de Désor-meaux.Lemelin, Jean-Guy.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent soixante-quatre (p.564) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha, comté de Joliette, mesurant cent pieds de largeur par la profondeur allant de la route du vieux moulin et la rivière Noire, borné à un bout par la route du vieux moulin, à l'autre bout par la rivière Noire, d'un côté par partie 564 au vendeur et de l'autre côté à Rolland Landreville.Marcel Trudeau & Paul Rainville, synd.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent quatre-vingt-cinq (p.585) aux plan t livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha, mesurant 125' de largeur, plus ou moins, sur la profondeur qu'il y a d'une ligne passant à 75' environ du côté nord-ouest d'un chemin privé de vingt-trois pieds de largeur, qui traverse le terrain vendu du nord-est au sud-ouest, à aller au lac Noir et borné comme suit: vers le nord-est par partie 585 à Dame Laurent Richard ou représentants, vers le nord-ouest par la ligne mentionnée ou autre partie 585 appartenant à Athanase Baril, vers le sud-ouest par un fossé.Une autre partie du 585 du cadastre susdit mesurant 160' de largeur en front le long d'un chemin privé sur une profondeur de 130' dans la ligue de Pierre Jette et d'environ 110' dans l'autre ligne, mesure anglaise et plus ou moins, borné comme suit: en front par un chemin privé, en arrière par un fossé, d'un côté par partie 585 à Pierre Jette et de l'autre côté par partie 585 à Guy Rivest.15.99 15.99 A part of land being in the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, known and designated as being a part of lot twenty (p.20) of the said cadastre for the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, south part of an emplacement belonging to André Dallaire, on the southwest from the road, containing one hundred and thirty eight feet in width along the road and 120 feet in rear by 100 feet depth and bounded as follows: in front hy the road, in depth by the southwest by Orner Laramé, by the northwest by Dallaire and by the southeast by the land of Desormeaux.79.95 60.88 140.83 A part of land known and designated as being a part of lot five hundred and sixty-four (p.564) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, Joliette County, measuring one hundred feet in width by the depth from the old mill road to the Black River, bounded at one end by the old mill road, at the other end by the Black River, on one side by part 564 belonging to the vendor and on the other side by Rolland Landrevule.147.90 147.90 A part of land known and designated as being a part of lot five hundred and eighty-five (p.585) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, measuring 125' in width, more or less, by the depth existing at 75' on the northwest side of a private road measuring 23' in width and crossing the land presentely sold by the southwest to Lac Noir; bounded as follows: by the northeast by part of 585 belonging to Dame Laurent Richard or representatives, by the northwest by the hereabove line or part of 5S5 belonging to Athanase Baril, by the southwest by a crick.Another part of 5S5 of the said cadastre measuring 160' in width bv the front of the road by 130 feet depth in the line of Pierre Jette and about 110 feet in the other line, English measure and more or less, bounded as follows in front by a private road, in rear by a crick, on one side by part of 685 belonging to Pierre Jette and on the other side by part 685 belonging to Guv Rivest. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 187 Corporation municipale St-Jean-de-Matha Municipal Corporation (suite-continued) Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes Levesque, Jean-Marie.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot quatre cent trente-sept A (p.437A) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jean-de-Matha mesurant cent soixante pieds de largeur sur cent pieds de profondeur et borné comme suit : en front vers le sud-est par la rivière Noire, en profondeur vers le nord-est par autre partie 437A restant la propriété du vendeur, d'un côté vers le nord-ouest par la clôture existante sur le chemin public de St-Jean-de-Matha-Ste-Béatrix et de l'autre côté vers le sud-est par le terrain appartenant à Marcel Corbeil ou représentants.Nicol, Jacques.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot cent un (p.101) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Matha pour la partie de Brandon mesurant 50' de largeur sur 250' de profondeur, plus ou moins et borné au sud-est par le lac Mondor, au sud-ouest par le lot 102 et au nord-est et ouest par partie du 101 restant au vendeur.Martin, P.-Robert.Un emplacement situé en la paroisse de SWean-de-Matha pour la partie de Brandon étant une partie du lot vingt-deux aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Matha pour la partie de Brandon, pris ledit terrain au sud-ouest du chemin qui conduit aux emplacements de Rivard & Trépanier de cent pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins, et borné comme suit: en front au nord-est par le chemin public, au sud-est par un terrain de cinquante pieds de largeur séparant ce terrain celui de Rivard & Al et de tous autres côtés par Paul-Emile Bellerose ou représentants.Dozois, Robert.Un terrain faisant partie du lot numéro cent un (P.101) connu et désigné comme faisant partie dudit lot aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha pour la partie de Brandon ayant une superficie de 7000 p.c, la ligne nord-ouest est située à 225 pieds environ du lac et la ligne sud-ouest à 175 pieds de la ligne de division du lot 101 et 102, borné au nord-ouest et sud-ouest par des rues et au nord-ouest et sud-est par autres parties 101.Rose-Alba Roch-Ducharme.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot trois cent cinquante-quatre (p.354) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha, mesurant cinquante pieds de largeur par un arpent et demi de profondeur et borné comme suit: en front par le chemin public, en arrière par les représentants de Nap.Charbonneau, d'un côté par Clément Charbonneau et de l'autre côté par Gerald Roberge.Une autre lisière de terre faisant partie du lot 355 aux plan et livre de renvoi officiels susdits mesurant dix pieds de largeur sur un arpent et demi de profondeur borné en front par le chemin public à l'autre bout au terrain de Fr.Bazinet d'un côté audit Bazinet et de l'autre côté à partie 354 ci-haut décrite.Forgues, Normand.Un terrain connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cinq cent quatre-vingt-cinq aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jean-de-Matha situé à l'est d'un chemin privé et mesurant 105' de largeur sur ledit chemin par $ 27.98 S 27.98 A part of land known and designated as being a part of lot four hundred and thirty-seven A (p.437A) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha measuring one hundred and sixty feet in width by one hundred feet in depth and bounded as follows: in front towards the southeast by the Black River, in depth towards the northeast by a part of 437A belonging to the vendor, on one side towards the northwest by the fence existing on the public road St-Jean-de-Matha-Ste-Béatrix and on the other side towards the southeast by the land belonging to Marcel Corbeil or representatives.$ 11.15 26.24 37.39 A piece of land known and designated as being a part of lot hundred and one (p.101) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, measuring 50' in width by 250' in depth and bounded as follows: by the southeast Lac Mondor, by southwest lot 102, by the northeast part of 101 vendor.17.22 17.22 A piece of land in the parish of St-Jean-de-Matha for the township of Brandon being a part of lot twenty-two (p.22) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha for the Brandon Township, this land being on the southwest of the road leading to the emplacements of Rivard and Trépanier, measuring one hundred feet in width by one hundred feet in depth, English measure and more or less and bounded as follows: in front towards the northeast by the public road, towards the southeast by a land of fifty feet In width cutting this land from Rivard & Al, and in all other sides by Paul-Emile Bellerose or representatives.38.23 77.16 115.39 A piece of land being a part of lot one hundred and one (p.101) known and designated as being part of the said lot on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, having an area of 7000 s.f.the northwest line being at 225 feet from the lake and the southwest line at 175 feet from the division line for lots 101 and 102, bounded as follows towards the northwest and the southwest by streets and towards the northwest and southeast by other parts of 101.46.16 46.16 A piece of land known and designated as being a part of the lot three hundred and fifty-four (p.354) on the official plan and book of reference for the parish of St^Jean-de-Matha, measuring fifty feet in width by an arpent and a half in depth and bounded as follows: in front by the public road, in rear by the representatives of Nap.Charbonneau, on one side by Clément Charbonneau and on the other side by Gerald Roberge.A piece of land being a part of lot 355 on the said plan and bçok of reference measuring ten feet in width by one arpent and a half in depth and bounded as follows: in front by the public road, at the other end by the land of Fr.Bazinet, on one side to the said Bazinet and on the other side by part of 354 hereabove described.59.63 133.52 193.15 A piece of land known and designated as being a part of lot five hundred and eighty-five on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha placed on the east of a private road and measuring one hundred and five 188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104\" année, n° 2 Corporation municipale St-Jean-de-Matha Municipal Corporation (suite) \u2014 (continued) la profondeur dudit chemin à aller au Lac Noir, borné à un bout par le chemin privé, à l'autre bout par le lac Noir, d'un côté à Lorenzo Levesque et de l'autre côté par M.Provost ou représentants*.Gauthier, Jean Un terrain connu et désigné comme faisant partie du lot cent un aux plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de St-Jean-de-Matha.partie Brandon, mesurant 60* rie largeur sur 500' de profondeur, plus ou moins, borné au sud-ouest par le lot 102, au sud-est par partie 101 au vendeur, étant une rue projetée, au nord-ouest par la ligne de division du rang X, au nord-est par partie dudit lot au vendeur.Grignon, Pierre.Un emplacement ayant front sur la rivière Noire, en la paroisse de St-Jean-de-Matha, comté de Joliette, connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent vingt-deux (p.522) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Jean-de-Matha mesurant ledit emplacement 125' de largeur par 125' de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins, borné comme suit: en front par la rivière Noire, des trois autres côtés par le résidu du 522 appartenant à Yves Geoffroy ou représentants.Dame Emilienne Vermette-Tessier.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot uatre cent quatre (p.404) aux plan et livre de renvoi officiels e la paroisse de St-Jean-de-Matha, mesurant 75' de largeur sur 300' de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné comme suit: à un bout à un chemin privé, à l'autre bout et du côté sud-est par parties 404 appartenant au vendeur et du côté nord par le lot 403, avec bâtisses y érigées.Frank Di Fabio Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 21 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Matha, pour la partie de Brandon, de la contenance de 16 acres et borné de tous les côtés par l'ancien et le nouveau chemin.Petit, Jacques.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot trois cent quatre vingt-neuf (p.389) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Jean-de-Math a mesurant 200' de largeur par 100' de profondeur borné en front et au nord-est par les termina de l'acquéreur et de Robert Petit, en profondeur au sud-est par le vendeur et au sud-ouest par Jacqueline Gatien et au nord-est par le vendeur.Geoffroy, Yves Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent soixante-dix (p.570) aux plan et livra de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-de-Matha mesurant 300' de largeur par 334' de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné en front par le chemin public, en arrière, sur une longueur de 180' par le terrain de Trefflé Comtois ou représentants et sur une longueur de 120' par Agnus Archambault, d'un côté par un chemin privé et de l'autre côté par partie 568.Un autre terrain du même faisant partie du même lot 570 comprenant tout le terrain compris dans les limites suivantes: à un bout à la route nationale, à l'autre bout à partie 570 feet in width on the said road by the depth from the road to Lac Noir, bounded on one end by a private road, on the other end by the Lac Noir, on one side by Lorenzo Levesque and on the other side by M.Provost or representatives.Taxes scol.Total School taxes S 19.07 S 49.95 S 69.02 A piece of land known and designated as being part of lot one hundred and one (p.101) on the official plan and book of reference for the parish of St>Jean-de-Matha.township of Brandon, measuring 50' in width by 500' in depth, more or less, bounded towards the southwest by lot 102, towards the southeast by part 101 to the vendor being a street, towards the northwest by the division line on range X, towards the northeast by part of said lot to the vendor.3.96 28.30 32.26 An emplacement being in front on the Black River, in the parish of St-Jean-de-Matha, Joliette County, known and designated as being a part of lot five hundred and twenty-two on the official plan and book of reference for the parish of Si-Jean-de-Matha, measuring the said emplacement 125' in width by 125' in depth, English measure, more or less, bounded as follows: in front by the Black River, on the other three sides by parts of 522 belonging to Yves Geoffroy or representatives.150.84 150.84 A piece of land known and designated as being a part of lot four hundred and four (p.404) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, measuring 75' in width by 300' in depth, English measure and more or less, bounded as follows: at one end by a private road, at the other end and towards the southeast by parts 404 belonging to the vendor and towards the north side by the lot 403, with the buildings thereon erected.13.46 13.46 A piece of land known and designated as being a part of lot 21 on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha, township of Brandon, containing 16 acres and bounded on all sides by the new and the old road.94.03 94.03 A piece of land known and designated as being a part of lot three hundred and eighty-nine (p.389) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha measuring 200 in width by 100' in depth bounded in front towards the northeast by the buyer's lands and Robert Petit, in depth on southeast by the vendor and towards the southwest by Jacqueline Gatien and towards the northeast by the vendor.40.64 152.63 193.27 A piece of land being a part of lot five hundred and seventy (p.570) on the official plan and book of reference for the parish of St-Jean-de-Matha measuring 300' in width by 334' in depth, English measure and more or less, bounded in front by the public road, in rear for 180' by the land of Trefflé Comtois or representatives and for 120' by Agnus Archambault or representatives, on one side by a private road and on the other side by part of 568.Another land being a part of the same lot 570 comprising all the Innd bounded as follows: on one end by the public road on the other end by part of 570 belonging to succ.A.Selauder' Noms Names Taxes munie.Descriptions Munie, taxes QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol 104, No.2 189 Corporation municipale St-Jean-de-Matha Municipal Corporation (suite \u2014 continued) appartenant à la succ.A.Selander, d'un côté par le terrain ci-haut décrit et de l'autre côté par un chemin privé allant de la route Nationale au Lac Noir à distraire de ce terrain deux emplacements décrits audit acte.on one side by the land hereinabove described and on the other side by a private road leading to the public road from Lac Noir to withdraw of this lots two emplacements described.Corporation municipale de Ste-Béatrix Municipal Corporation (cadastre de-of Ste-Béatrix) Taxes Taxes Noms munie scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes 78-88.78-26.65-3.77-54.78-23.77-90.78-24.Domaine Lac Vallée (1969) inc.& G.Faber.Dev.Lac Vallée Inc.et Adan Gora>k.Czudak Teley Kinewska.Ben,o it-Bourdon , Éva.Karkantonatos, Maria.Snizyk, Dimitri.Destounis, Steve.Arbour, Marcel.Un terrain étant partie du lot cinquante-huit (P.58) du cadastre de la paroisse de Ste-Béatrix, comté de Joliette mesurant soixante-quinze pieds anglais de largeur par la profondeur qu'il y a du nouveau chemin public à aller au Lac Cloutier.borné d'un côté par Avila Arbour ou représentants et de l'autre côté audit Avila Arbour ou représentants, toutes parties 5S.A distraire de ce terrain ce qui en a été vendu par l'enregistrement 119434.Bélisle, Guy.Un emplacement situé en la paroisse de Ste-Béatrix, comté de Joliette.connu et désigné comme étant une partie du lot cinquante-sept (P.57) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de ladite paroisse de Ste-Béatrix.mesurant ledit emplacement soixante-six pieds et cinq centièmes de pied de largeur en front et quatre-vingt-un pieds de largeur en arrière sur une profondeur d'environ cent pieds, mesure anglaise plus ou moins, et borné comme suit: en front par un chemin privé, en arrière par le terrain appartenant a Leopold Malo ou représentants, d'un côté par le terrain appartenant à Adolphe Lajeunesse ou représentants et de l'autre côté par le terrain de Georges-Albert Poirier ou représentants.immeubles E.Loyer Ltée (les).Les lots 200.201 et 202 à distraire de ces lots la partie appartenant à Louis Ayotte et aussi à distraire ce qui en a été vendu aux enregistrements numéros: 129522.130258, 130850, 134743, 135243, 135344, 136540 et 152461 sur lot 200 130408, 130781, 130850 et 152463 sur lot 201.Lajeunesse, Jean-Marie.Un terrain étant partie du lot quatre-vingt (P.80) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Béatrix, comprenant tout le terrain renfermé dans les limites suivantes et borné comme suit: au nord-est par un chemin public, du côté nord-ouest par autre partie du lot 80, cette ligne nord-ouest étant à la distance de cinquante pieds de la ligne du lot 81, du côté sud-est à un ruisseau qui traverse le chemin public et en arrière à un autre ruisseau qui rejoint le ruisseau plus haut décrit.Alfred Perreault & Raymond & Cécile Beaudoin.Un terrain Bitué en la paroisse de Ste-Béatrix, connu et désigné comme étant une partie du lot trois cent dix-sept aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Ste-Béatrix, comté de Joliette, mesurant en front soixante-dix pieds sur la rivière l'Assomption par cent pieds de profondeur et borné comme suit: en front par la rivière l'Assomption, 65t20.S 79.48 S 79.48 .10.10 S 20.00 30.00 .13.50 13.50 .62.65 128.26 190.91 .11.00 21.97 32.97 .16.25 16.25 .64.55 42.28 106.83 287.74 287.74 A piece of land being a part of lot fifty-eight (P.58) on the officia! cadastre for the parish of Ste-Béatrix, Joliette County, measuring seventy-five feet English measure in width by the depth existing from the public road to Lac Cloutier, bounded on one side by Avila Arbour or representatives and on the other side by the same Avila Arbour, all parts 58.To withdraw the land sold in registration number 119434.41.23 170.60 211.83 An emplacement situated in the parish of Ste-Béatrix, county, known and designated as being a part of lot fifty-seven (P.57) on the official plan and book of reference for the parish of Ste-Béatrix, measuring the said emplacement sixty-six feet and five hundredth of feet in width by the front and eighty-one feet in width by the rear by about one hundred feet in depth, English measure and more or less and bounded as follows: in front by a private road, in rear by the land belonging to Leopold Malo or representatives, on one side by the land of Adolphe Lajeunesse or representatives, on the other side by the land of Georges-Albert Poirier or representatives.266.14 560.92 827.00 Lots Nos.200.201 and 202 to withdraw from these lots the part belonging to Louis Ayotte and also to withdraw the parts of lots sold by registration numbers: 129522.130258.130850, 134743, 135243.135344, 136540 and 152461 on lot 200 130408, 130781, 130850 and 152463 on lot 201.435.42 435.42 A piece of land being a part of lot eighty (P.80) in the official plan and book of reference for the parish of Ste-Béatrix, comprising all the land closed by the next limits and bounded as follows: on the northeast by a public road, on one side towards the northeast by a public road, on one side towards the northwest by other part of 80, this line northwest being at a distance of fifty feet from the 81 line, towards the southeast side by a creek crossing the public road and in the rear, by an other creek joining the one hereabove described.91.00 175.04 266.04 A piece of land in the parish of Ste-Béatrix known and designated as being part of lot three hundred and seventeen (P.317) for the official plan and book of reference of the cadastre for the parish of Ste-Béatrix, measuring seventy feet in front on l'Assomption River, by one hundred feet in depth and bounded as follows: in front by l'Assomption 190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 1972, 104* année, ne 2 Corporation municipale de Ste-Béatrix Municipal Corporation (cadastre de-of Ste-Béatric) (suite) \u2014 (continued) d'un côté par partie 317 appartenant à David Lafrenière, en River, on one side by part of lot 317 belonging to David profondeur par autre partie dudit lot appartenant à Jean Lafrenière, in depth by part of the said lot belonging to Jean Jeansonne et de l'autre côté par partie 317 appartenant à Jeansonne, and on the other side by an other part of ow Marcel Bouchard, avec bâtisses y érigées.belonging to Marcel Bouchard, with the buildings thereon.Noms Names Descriptions Taxes munie.Munie.Taxes Taxes scol.School Taxes Total Géro Limitée.Un morceau de terrain faisant partie du lot numéro cinquante-six (P.56) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Béatrix, comté de Joliette.mesurant cent pieds de largeur sur cent quinze pieds de profondeur dans une ligne et cent soixante-quinze pieds de profondeur dans l'autre ligne et borné comme suit: en front par un chemin (nouveau chemin) en arrière par le lac Cloutier, d'un côté par autre partie 56 appartenant à Avila Arbour ou représentants et de l'autre côté par la partie ci-après décrite des lots 55 et 56.Un morceau de terrain faisant partie des lots 55 et 56 des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Béatrix mesurant cent cinquante pieds de largeur sur cent vingt-sept pieds de profondeur dans une ligne et 137 pieds de profondeur dans l'autre ligne et borné comme suit: en front par un chemin (nouveau chemin) en arrière par le lac Cloutier, d'un côté par partie 55 et 56 appartenant à M.Verdichio ou représentants et de l'autre côté par la partie 56 ci-haut décrite.S 97.93 $ 97.93 A piece of land being a part of lot fifty-six (P.56) on the official plan and book of reference for the parish of Ste-Béatrix, Joliette County, measuring one hundred feet in width by one hundred and fifteen feet in depth in one line and one hundred and seventy-five feel in ihe other line and bounded as follows; in front by a public road (new road) in rear by lac Cloutier.on one side by a part of 56 belonging to Avila Arbour or representatives and on the other side by the land hereinafter described and being parts of 55 and 56.A piece of land being a part of lot 55 and 56 on the official plan and »book of reference for the parish of Ste-Béatrix measuring one hundred and fifty feet in width by one hundred and twenty-seven feet in depth in the first line and one hundred and thirty-seven feet in depth in the other line and bounded as follows: in front by a public road (new road), in rear by Lac Cloutier, on one side by part 55 and part 56 belonging to M.Verdicchio or representatives ana on the other side by the part 56 hereabove described.Corporation municipale Ste-Marcelline de-o£ Kildare Municipal Corporation (cadastre de-of St-Ambroise) Lot No 419-23, St-Ambroise 532-25.530-32.531-180.____ Marie-Louise Bogdan.Smiljka BrnjaWMorris.Syntfwiecka, Olga.Bussing.Henry A.Caron, Normand.Un terrain faisant partie du lot cinq cent trente (P.530) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise borné au nord par le lot 530-25.à l'est et au sud par parties 530, à l'ouest par les eaux les plus hautes du lac Léon, mesurant dans sa ligne nord 108.3', dans sa ligne est 60', plus ou moins, dans sa ligne sud 100' plus ou moins, dans sa ligne ouest 45'.Godwin, Joan.Un terrain faisant partie du lot cinq cent trente et un (P.531) borné en front à l'ouest par une rue projetée étant le prolongement de la rue 531-10 et de tous les autres côtés par partie 531, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur.Cadastre de la paroisse St-Ambroise.Herhner, Hermann William.Un terrain faisant partie du lot 419 du cadastre de la paroisse de St-Ambroise mesurant 50' de largeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest, par 100' de profondeur dans ses lignes nord-ouest et sud-est, plus ou moins, borné par partie 419 â G.H.Holfelder, au nord-ouest par Raymond Ishii, au nord-est par un chemin privé et au sud-est par partie 419 au vendeur.Latka, Josapha.Un terrain faisant partie du lot originaire No 553 du cadastre de la paroisse de St-Ambroise mesurant 50' de largeur en front et en arrière par une profondeur de 105' dans ses lignes nord-est et 95% dans ses lignes sud-ouest, plus ou moins, borné en front au sud-est par une rue projetée, en arrière au nord-ouest par autre rue projetée au sud-ouest par une autre rue et au nord-est par partie 553.$ 5.17 $ 18.31 ï 23.48 .39.95 136.68 176.63 .3.52 12.77 16.29 .23.63 51.67 75.30 4.72 17.81 22.53 A piece of land being a part of lot five hundred and thirty* (P.530) on the official plan and book of reference for the parish of St-Amhroise bounded towards the north by lot 530-25.towards the east and the south by parts of 530, towards the west by the highest waters of the lake Léon, measuring on its north line 108.3, in its east line 60', more or less, in its south line 100' more or less, in its west line 45'.3.53 12.78 16.31 A piece of land being a part of lot five hundred and thirty-one (P.531) bounded in front towards the west by a street in project ending to the street 531-10 and on all other sides by parts 531, measuring 50' in width by 100 feet in depth St-Ambroise cadastre.4.38 16.58 20.96 A piece of land being a part of lot 419, St-Ambroise Cadastre measuring 50' m width in its northeast and southwest lines by 100' in depth in its southeust and northwest lines, more or less, bounded as follows by part belonging to S.H.Holfelder on the northwest by Raymond Ishii.on the northeast by a private road and towards the southeast bv part 419 helontrinff to the vendor.9.40 32.10 41.50 A piece of land being a part of lot five hundred and fiftv-three in the parish of Ste-Marcelline on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise measuring 50' in with in front and in rear by 105 in depth in its northeast line and 95' in its southwest line, more .or less, bounded in front towards the southeast by a street, in rear towards the northwest by an other street and the same towards the south west and towards the northeast by part of 553. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 26, 1972, Vol.101>.No.2 19] Corporation municipale Ste-Marcelline-de-of Kildare Municipal Corporation (cadastre de-of St-Ambroise) (suite) \u2014 (continued) Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes Landschek, Gisela.Un terrain faisant partie du lot 531 au cadastre de la paroisse de St-Ambroise borné vers le nord et le sud-ouest et vers le sud par partie 531, vers le nord-est par autre partie 531, mesurant dans sa ligne nord et sud 100' de profondeur par 50' de largeur.Le coin nord-est est situé à une distance de 950' de la ligne séparant les lots 531 et 532.Mahoney, Richard.Un terrain faisant partie du lot 531 au cadastre de la paroisse de St-Ambroisc mesurant 126.07' en front au sud-est d'une rue projetée, 109.25' en arrière au nord-ouest, d'un côté au nord-est et 89.35' de l'autre côté au sud-ouest, superficie 8921.Borné de tous les côtés par le vendeur.Nuez, Leopoldo.Un terrain faisant partie du lot 419 au cadastre de la paroisse de St-Ambroise, mesurant 100' de largeur sur 100' de profondeur, borné au nord-ouest par un chemin privé appartenant au vendeur, au sud-est par partie du même lot appartenant à Alexis Chevalier ou représentants, et de tous les autres côtés par partie 419.Rondeau, Guy.Un terrain de figure irrégulière faisant partie du lot 552 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise de Kildare, mesurant 180' vers le nord, 140' vers le sud.300' vers l'est et 200' vers l'ouest et borné vers le nord par un chemin public, vers l'est par le terrain de Albert Thouin, vers le sud et vers l'ouest par autre partie 552 appartenant au vendeur.Werner.Sphmidt.Un terrain étant une partie du lot 532 aux plan et livre de renvoi officiel pour la paroisse de St-Ambroise borné au nord-est par partie 532, au sud-est par 532-307, au sud-ouest par partie 532 au nord-ouest par partie 532 mesurant 25' de largeur par 100' de profondeur.Superficie de 2,500.Vanderkolf, Johannes.Un terrain faisant partie du lot 529 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise de Kildare borné au nord par partie 529, à l'est par une rue projetée, au sud par partie 529 autre rue projetée, à l'ouest par partie 529.Superficie de 5000 p.c, mesurant 50' par 100'.Karl, E.Pfaff.Un terrain faisant partie du lot 419 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise, mesurant 82' dans sa ligne sud-est, 200' dans sa ligne sud-ouest suivant une ligne brisée, 225' plus ou moins le long d'un ruisseau.Superficie de 9536 p.c.Borné au sud-est par un chemin privé, au nord-est par un ruisseau et au sud-ouest par partie 419.Rocheleau, Réal.Un terrain en la paroisse de Ste-Marcelline étant une partie du lot 7A du 12ième rang du canton de Kildare aux plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de Saint-Alphonse, mesurant 100' de largeur par 100' de profondeur et borné comme suit: en front par autre partie 7A appartenant à Gérard Guérin, du côté nord-ouest par un chemin privé, de l'autre côté et en profondeur par autres parties du même lot appartenant à Gérard Guérin.$ 2.62 $ 8.52 S 11.14 A piece of land being a part of lot 531 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise bounded towards the north and southwest and the south by parts of 531, towards the northeast by other part of 531, measuring in its north line and south line 100' in depth by 50' in depth, the northeast corner being at a distance of 950' from the division line for lots 531 and 532.6.35 21.82 28.17 A piece of land being a part of lot 531 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroi3C measuring 126.07' in front towards the southeast of a street in project.109.25' in rear towards the northwest, on one side towards the northeast, and 89.35 on the other side towards the southwest.Area of 8921.Bounded on every sides by the vendor.16.06 16.06 A piece of land being a part of lot 419 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise measuring 100' in width by 100' in depth, bounded by a private road belonging to the vendor towards northwest, towards the southeast by part of the same lot belonging to Alexis Chevalier or representatives and on every sides by parts of 419.5.43 20.19 25.52 A piece of land of irregular figure being a part of lot 552 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise of Kildare, measuring 180' towards the north, 140' towards the south, 300' towards the east and 200' towards the west and bounded towards the north by a public road, towards the east by the land of Albert Thouin and towards the south and west by parts of 552 belonging to the vendor.1.64 5.84 7.48 A piece of land being a part of lot 532 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise of Kildare, bounded towards the southeast, southwest and northwest by parts of 532 and towards the southeast by 532-307, measuring 25' in width by 100' in depth.Area of 2,500.588 20.84 26.72 A piece of land being a part of lot 529 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise of Kildare bounded towards the north by a part of 529, towards the west by a street in project, towards the south by an other street in project and towards the west bv part 529.Measuring 50' by 100', area of 5000 s.f.3.50 13.16 16.66 A piece of land being a part of lot 419 on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise, measuring 82' in its southeast line, 200' in its southwest line on a broken line, 225'.more or less, along a creek.Area of 9536 s.f.Bounded towards the southeast by a private road, towards the northeast by a creek and towards the southwest by a part of 419.7.06 24.73 31.79 A piece of land in the parish of Ste-Marcelline being a part of lot 7A of 12th range of the township of Kildare on the official plan and book of reference for the parish of St-Alphonse, measuring 100' in width by 100' in depth and bounded as follows: in front by a part of 7A belonging to Gérard Guérin, towards the northwest by a private road, on the other side and in depth by other parts of 7A belonging to Gérard Guérin. 192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 10J,' aimée, n° S Corporation municipale Ste-Marcelline-de-of Kildare Municipal Corporation (cadastre de-of St-Ambroise) (suite) \u2014 (continued) Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions lotal Names Munie.School taxes taxes Rioux, Guy.Un terrain en la paroisse de Ste-Marcelline étant une partie du lot 7 A du 12ième rang du canton de Kildare, aux plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de Suint-Alphonse, comté de Joliette, mesurant 100' de largeur par 100' de profondeur, borné au nord-est et nord-ouest par un chemin privé, au sud-ouest par M.Bordeleau et au sud-est par le vendeur.Les Domaines Fontainebleue Limitée.Les subdivisions Nos:.The Subdivisions Nos:.on ! ho official plan and book of reference for au plan et livre de renvoi officiels pour: 8 11.75 S 40.88 S 52.63 A piece of land in the parish of Ste-Marcelline being a part of lot 7A of 12th Range of the township of Kildare on the official plan and book of reference for the parish of St-Alphonse, measuring 100' in width by 100' in depth and bounded as follows: towards the northeast and northwest by a private road, towards the southwest by M.Bordeleau and towards the southeast by the vendor.730.84 2.809.88 3.530.72 Cadastre de St-Ambroise Cadastre of St-Ambroise Un certain lopin de terre comprenant les lots numéros cinq cent vingt-neuf, cinq cent trente, cinq cent trente et un, cinq cent trente-deux (529, 530.531 et 532) du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise, division d'enregistrement de Joliette.Borné au nord-est par les lots Nos 533 and 534.au sud-est par les lots Nos 515, 516 et 517 et une partie du lot No 518, au sud-ouest par le lot No 528, au nord-ouest par une partie du lot No 2A.les lots Nos 2B, 3A et 3B, Rang XII.augmentation de Kildare.Ces lots mesurant dix arpents (10 arp.) de largeur par douze arpents (12 arp.) de profondeur chacun et forment une superficie de cent vingt arpents carrés (120 arp.car.) ou cent un acres et trente-sept centièmes d'acre (101.37 acres) chacun.A distraire la partie du lot No 530, mesurant deux arpents (2 arp.) par douze arpenta (12 arp.) ia partie du lot No 529, mesurant deux arpents (2 arp.) par douze arpents (12 arp.).Ces deux lopins de terre étant situés à l'extrémité sud-ouest du lopin de terre ci-haut décrit, à distraire aussi une partie du lot No 629, mesurant deux arpents (2 arp.) par six arpents (6 arp.).Ce lopin de terre étant situé du côté nord-ouest du lot No 529, ci-haut décrit.À distraire de ceux-ci les parties vendues par contrats enregistrés sous les numéros suivants: 529-1, -2.-3.-4.-5.-6, -8.-9.-10.-11.-12.-21.-22, -23, -24.-32, -34, -35, -36, -37, -38.530-1,-2, -11.-13, -18, -27, -28, -29, -30, -33, -38, -40, -41, -47, -52.531-3, -4, -5, -6, -7, -S, -9.-10.-11, -13, -14, -15, -17, -21, -23, -24, -25, -26,-33, -35, -36.-37,-38,-39,-40.-41.-44,-45,-47,-48,-50, -51, -52, -53, -54, -55.-56, -57, -59, -60, -66, -78,-79,-82,-83,-84,-90,-91, -92,-93.-94, -95,-96,-101,-104,-105,-106.-107,-108, -109, -110,-111,-112,-113,-114,-115,-116,-117.-119,-120,-123,-133,-136,-141.-148,-160, -164,-176,-179,-181,-185,-187.532-1, -2, -3, -4, -5, -6.-7.-8.-9, -10, -11, -12,-13,-14,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22.-24,-26,-27,-28,-30,-31,-32,-33,-34,-37, -38, -39, -40, -41.A land including lots 6ve hundred and twenty-nine (529), five hundred and thirty (530), five hundred and thirty-one (531) and five hundred and thirty-two (532) on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise, Joliette registry division.Bounded on northeast by lots 533 and 534, on southeast by lots 515.516 and 517 and a part of 518.on southwest by No.528.on northwest by a part of lot 2A and lots 2B.3A and 3B of the 12th range des Aug.de Kildare.These lots measure ten arpents in width bv 12 arpents in depth for an area of 120 s.a.Less and to be deducted from lot 530 measuring 2 arpents by 12 arpents and the same area from lot 529.These two parts of land being at the end southwest of the lots hereabove described.To be deducted also from 529 a part of land of 2 arpents by 6 arpents.This last part of land being on the northwest side of 529.Less and to be deducted therefrom the portions sold in the deeds registered under the following numbers: 137259,138421,140062.140594,140851.142317, 144323,148291, 148366,149356.126632.Corporation municipale de Ste-Émélie Municipal Corporation Robert, Jean.Charsil Holdings Ltd.Un terrain partant à deux cents pieds de la ligne de division entre le canton Tracy et le canton Courcelles extrait du lot quarante-quatre B, (p.44B) du premier rang du canton Tracy aux plun et livre de renvoi officiels dudit canton Tracy, comté No 4, 5e-th rg-rge, canton-township Joliette.S 6.20 48.66 9 47.79 S 53.99 100.88 149.54 A part of lot starting from two hundred feet from the division line between the township of Tracv and the townshin of Courcelles being a part of lot forty-four B (P.44B) Qf first range for the township of Tracy on the official'plan and QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.S Corporation municipale de Ste-Emélie Municipal Corporation {suite \u2014 continued) de Joliette et borné comme suit: en avant ce terrain commence à deux cents pieds de la ligne de division entre le canton Courcelles et le canton Tracy, en arrière par le lot 44A, d'un côté par 43B et de l'autre côté par 45B.Un terrain partant à 200 pieds de la ligne de division entre le canton Tracy et le canton Courcelles étant la juste moitié nord du lot 45B dudit cadastre.book of reference of the said township of Tracy, Joliette County, and bounded as follows: in front this part of lot begins at two hundred feet from the division line for the township of Tracy and the township of Courcelles, in rear by the lot No.44A, on one side by 43B and on the other side by 45B.A part of land starting from two hundred feet of the division line between the township of Tracy and the township of Courcelles being the just half north of the lot 45B.Corporation municipale St-Côme Municipal Corporation Taxes Taxes Noms munie.scol.Descriptions Total Names Munie.School taxes taxes Perri, Dame Armand.Lots Nos 14-R.10.Catficart.$24.70 $231.90 $ 256.60 15, 16, R.11.Cathcart.Lachapelle, Léo.Lot No 17-28.R.3, Cartier.40.65 87.08 127.73 Domaine Lac Clair Ltée.Lot No 15, R.10.Cathcart.63.45 131.74 195.19 À distraire de ce lot les parties vendues aux enregistrements To withdraw of this lot the parts sold by registration suivants: 143797-1442S3.144284, 144285, 144286.144287, numbers: 143797-144283, 144284, 144285, 144286.144287.144288, 144289, 144290, 144291, 144292, 144468.146603.144288, 144289, 144290.144291, 144292, 144468, 146603.Plass, Richard.Une partie de terrain faisant partie du lot 46 du 6ième rang du canton Cathcart en la paroisse de St-Côme, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, borné en front au sud-ouest par un chemin privé, en arrière au lot 47, d'un côté au nord-ouest et de l'autre côté au sud-est par parties 46.Rose-Mary Wiggins-Mansfield.Une partie de terrain faisant partie du lot 15 du rang X du canton Cathcart en la paroisse de St-Côme, mesurant 100' de largeur par 100' de profondeur, borné au nord-est par le lot 16 même rang et des trois autres côtés par parties 15, sa ligne nord-ouest est située à environ 150' de la ligne de division des rangs 10 et 11.5.47 5.47 A part of lot being a part on lot 46, 6th Range Township of Cathcart.in the parish of St-Côme.measuring 50' in width by 100' in depth bounded in front by a private road, in rear by lot 47, on one side towards the northwest and on the other side towards the southeast by parts on same lot 46.3.50 12.96 16.46  part of lot being a part of lot 15, 10th range Township of Cathcart in the parish of St-Côme, measuring 100' in width by 100' in depth bounded towards the northeast by lot 16 same range and on three other sides by parts of same lot 15, its northwest line being about 150' from the division line for 10th and 11th ranges.Corporation municipale de St-Ambroise Municipal Corporation Taxes Taxes Noms munie.scol.Frais Descriptions Total Names Munie.School Cost taxes taxes Banray Inc.Un terrain extrait du lot soixante-deux (P.62) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise, division d'enregistrement de Joliette ayant quatre-vingt-cinq pieds anglais de largeur sur le chemin public sur une profondeur de quatre-vingt-cinq pieds anglais, borné comme suit: en front au sud-est par un chemin public, en profondeur au nord-ouest à autre partie 62 appartenant a J.-Geo.Benny ou représentants, du côté nord-est à autre partie 62 appartenant à Normand Beaufils ou représentants et de côté sud-ouest par autre partie 62 appartenant ù Gilles Beauséjour.Bertrand, René.Un terrain faisant partie du lot soixante-sept (p.67) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise, mesurant cent cinquante-sept pieds au nord-ouest où borné par partie 62 vendue à Charles-E.Lachance, $ 38.88 £115.56 S 15.11 $ 169.55 A lot of land extracted from lot sixty-two (P.62) of the official plan and book of reference of the parish of St-Ambroise, Joliette Registry Office, measuring eighty-five English feet in width on the public road by a depth of eighty-five feet, bounded as follows: in front on the southeast by a public road, in depth on the northwest by an other part of 62 belonging to J.-Geor.Benny, on the northeast side to an other part of 62 belonging to Normand Beaufils or representatives and on the southwest side by an other part of 62 belonging to Gilles Beauséjour.62.83 128.01 17.31 198.16 A lot of land being a part of lot sixty-seven (P.67) of the official plan and book of reference for the parish of StrArabroise, measuring one hundred and fifty-seven feet on the northwest where bounded by part of 62 sold to Charles E.Lachance, 194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1973, 101' année, n° S Corporation municipale de St-Ambroise Municipal Corporation (suite) \u2014 (continued) deux cent quarante-cinq pieds au nord-est où borné à un chemin privé, trois cents pieds au sud-ouest où borné à la route 42 et trente-six pieds à l'est où borné à un chemin privé, two hundreds forty five feet on the northeast where bounded by a private road, three hundred feet on the southwest where bounded by the public road No.42 and thirty-six feet on the east where bounded by a private road.Taxes Taxes Noms munie.scol.Frais Descriptions Total Names Munie.School Cost taxes taxes Century Holdings Ltd.Un emplacement situé à St-Ambroise de Kildare, comté de Joliette, faisant partie du lot cent quatre vingt-dix-sept aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de St-Ambroise de Kildare, division d'enregistrement de Joliette, mesurant quatre-vingt-dix pieds do largeur par une profondeur do soixante-dix pieds, borné en front vers le sud, par la 28e avenue, en arriére vers le nord par Gaétan Beauséjour ou représentants, d'un côté vers l'est par Nap.Olivier ou représentants et de l'autre côté vers l'ouest par la partie du même lot appartenant au vendeur.Charland-Gravel, Gertrude.Un terrain de forme triangulaire connu et désigné comme faisant partie du lot soixante-cinq B, partie 65B, aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Ambroise, comté de Joliette, borné vers le nord-ouest par la route 42 où il mesure soixante-cinq pieds, vers le nord-est par l'ancienne route 42 où U mesure cent soixante-cinq pieds, et vers le sud-ouest par les terrains de la succ.W.Loiselle où il mesure cent quatre-vingt-quinze pieds, mesure anglaise, plus ou moins.Robillard, Maximilien.Un terrain situé dans le rang 5 du canton de Kildare, en la paroisse de St-Ambroise de Kildare, connu et désigné comme faisant partie du lot deux cent sept (p.207) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise mesurant soixante-quinze pieds de largeur en front au sud-est sur cent dix pieds de profondeur, mesure anglaise, et borné comme suit: en front au sud-est par un chemin privé de passage communiquant avec le chemin public, en profondeur au nord-ouest et d'un côté au sud-ouest par autres parties 207 restant au vendeur et de l'autre côté au nord-est par la ligne du lot 211 appartenant à Fernand Beauséjour.Parent, Claude.Deux aqueducs, l'un dans le rang 4 et l'autre dans le rung Double, paroisse de St-Ambroise, consistant en : 1) un morceau de terrain extrait et faisant partie du lot soixante-onze (p.71) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Ambroise de Kildare, mesurant vingt pieds de largeur sur vingt pieds de longueur, mesure anglaise, et borné comme suit: en front par le chemin public, en profondeur et du côté sud-ouest par le surplus dudit lot appartenant à Alfred Savoie, et du côté nord-est par le lot 70 dudit cadastre.2) Les sources d'eau provenant des lots de terre Nos 63, 64, 61 et 62 desdits plan et livre de renvoi.S 30.79 $ 110.31 $ 18.33 S 170.20 An emplacement situated in St-Ambroise, Joliette County, being a part of lot one hundred and ninety-seven of the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise of Kildare, Joliette Registry Office, measuring ninety feet in width by seventy feet in depth, bounded in front on the south by the 28th Avenue, in the rear on the north by Gaétan Beauséjour or representatives, on one side on the east by Nap.Olivier or representatives and on the other side towards the west by part of same lot belonging to the vendor.30.06 431.73 37.16 498.95 A lot of land of triangular figure known and designated as being a part of lot sixty-five B (P.65B) on the official plan and book of reference for the parish of St-Ambroise, Joliette County, bounded towards the northwest by the 42 road where it measures sixty-five feet, towards the northeast by the old 42 road where it measures one hundred and sixty-five feet and towards the southwest by the W.Loiselle succ.lands where it measures one hundred and ninety-five feet, English measure, more or less.27.81 3.82 31.63 A lot of land situated in the 5th range of the township of Kildare, in the parish of St-Ambroise of Kildare, known and designated as being a part of lot two hundred and seven (P.207) in the official plan and book of reference of St-Ambroise, measuring seventy-five feet in width in front towards the southeast by one hundred and ten feet in depth, English measure, and bounded as follows: in front on the southeast by a private road leading to the public road, on depth towards the northwest and on one side towards the southwest by other parts of 207 belonging to the vendor, and on the other side towards the northeast by the 211 line belonging to Fernand Beauséjour.202.04 597.46 49.64 849.14 Two aqueducts, the first in range 4th and the second in \"Rang Double\", parish of St-Ambroise, consisting in: (1) a piece of land extracted and being a part of lot seventy-one (f-J1) in,the officiaJ,P,an and book of reference for the parish of bt-Ambroise of Kildare, measuring twenty feet in width by twenty feet in depth.English measure, and bounded as follows: in front by the public road, in depth and on the southwest side by the remaining part of the same lot belonging to Alfred Savoie, and on the northeast side by the lot No.70 ?{ fx ïro3trfe;uC2ï ïhe, 8prinÇ* water risinS from lots 63, 64, bl and 62 of the said plan and book of reference.Corporation municipale de St-Thomas Municipal Corporation (cadastre de-of St-Thomas) vj__\u201e Taxes Taxes iNom3 _ inunic.scol.Descriptions T ., Names Munie.School taxes taxes Boucher, Maxime Adélard Lot No 371 * 5.65 S 17.65 S 22.90 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 195 Corporation municipale St-Çharles-Borromée Municipal Corporation (cadastre de-of St-Charles-Borromée) Noms Descriptions Names Racette, Paul.Lot No 285-13.Contré, Sylvio.Uh terrain faisant partie du lot deux cent quarante-deux (p.242) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Charles-Borromée, comté de Joliette, borné en front par la riviere L'Assomption où il mesure soixante-deux pieds, en profondeur par un chemin où il mesure soixante pieds, d'un côté par le terrain d'Adrien Contré où il mesure deux cents pieds, d'autre côté par le terrain de Charles Denis où il mesure deux cents pieds, mesure anglaise et plus ou moins, avec les bâtisses y érigées.Taxes Taxes munie.scol.Total Munie.School taxes taxes $134.06 $592.77 8 726.83 44.67 211.57 256.24 A piece of land being a part of lot number two hundred and forty-two (P.242) for the official plan and book of reference for the parish of St-Charles Borromée.Joliette County, bounded in front by L'Assomption river where measuring sixty-two feet, in depth by a private road where measuring sixty feet, on one side by the land of Adrien Contré where measuring two hundred feet, on the other side by Charles Denis where measuring two hundred feet, English measure and more or less, with all the buildings erected and all servitudes.Corporation municipale Ste-Liisabeth Municipal Corporation Lavallée.René.Un terrain désigné aux plan et livre de renvoi officiels pour la paroisse de Ste-Elisabeth comme faisant partie du lot deux cent soixante (p.260) contenant environ un demi arpent en superficie et borné comme suit: en front par le chemin public, en arrière par Albert Lefebvre et Ferme Léon Mercier Inc.(p.260), du côté sud par Jacques Casaubon (p.260) et du côté nord par Roger Guilbault (p.260) avec les bâtisses y érigées.91.88 $ 458.55 $ 550.43 A part of lot designated in the official plan and book of reference for the parish of Ste-Elisabeth as being a part of lot two hundred and sixty (P.260), having an area of about half an arpent and bounded as follows: in front by a public road, in rear by Albert Lefebvre and Ferme Léon Mercier Inc.(P.260) on one side towards the south by Jacques Casaubon (P.260) and on the other side towards the north by Roger Guilbault (P.260) with the buildings erected.Paroisse de St-Félix-de-Valois \u2014 Parish of St-Félix de Valois Geoffroy, Martial.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot quatre vingt-dix-huit (p.98) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Félix-de-Valois, division d'enregistrement de Joliette, mesurant cent dix pieds de largeur par cent quatre-vingts pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné comme suit: en front vers le nord par le chemin public (rue Principale), en arrière vers le sud par le terrain de Lionel Dufresne.d'un côté vers l'ouest au terrain de Roméo Beaulieu Sr, et de l'autre côté vers l'est par le terrain dudit Lionel Dufresne et partie par l'emplacement ci-après décrit: toutes: parties 98.Un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot quatre-vingt-dix-huit (p.98) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la paroisse de St-Félix-de-Valois, division d'enregistrement de Joliette, mesurant vingt-cinq pieds de largeur par quatre-vingt-dix pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, borné comme suit: en front vers le nord par le chemin public (rue Principale), en arrière vers le sud par le terrain de Lionel Dufresne, d'un côté vers l'est par celui de Gérard Houde et de l'autre côté vers l'ouest par le terrain ci-haut décrit: toutes parties 98.Avec les bâtisses y érigées.Gravel, Gérard.Un terrain en la paroisse de St-Félix-de-Valois, comté de Joliette, connu et désigné comme étant une partie du lot quatre cent soixante-seize A (p.476A) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Elisabeth, comté de Joliette, mesurant soixante-deux pieds et demi à un bout vers le sud et cinquante-cinq pieds vers le nord à l'autre bout par cent soixante et un pieds de profondeur dans la ligne ouest et cent cinquante-trois pieds dans sa ligne est, plus ou moins, borné comme suit: en front par un chemin privé de 25 pieds de largeur, à l'autre bout vers le nord par le terrain de L.Denobile et des deux côtés par B.Crevier.$ 56.21 $310.18 8 366.39 A piece of land known and designated as being part of lot ninety-eight (P.98) on the official plan and book of reference on the cadastre of St-Félix-de-Valois, Joliette Registry Office, measuring one hundred and ten feet in width by one hundred and eighty feet in depth, English measure and more or less, bounded as follows: in front towards the north by a public road (Principale Street), in rear towards the south by the land of Lionel Dufresne, on one side towards the east by the land of Roméo Beaulieu Sr.and on the other side by the land of the said Lionel Dufresne and part by the land hereafter described: all parts of 98.A piece of land known and designated as being part of lot ninety-eight (P.98) on the official plan and book of reference on the cadastre of St-Félix-de-Valois.Joliette Registry Office, measuring twenty-five feet in width by ninety feet in depth.English measure and more or less, bounded as follows: in front towards the north by a public road (Principale Street), in rear towards the south by the land of Lionel Dufresne, on one side towards the east by the land of Gérard Houde and on the other side by the land hereabove described: all parts of 98.With all the buildings constructed thereon.79.85 79.85 A piece of land in the parish of St-Félix-de-Valois, known and designated as being a part of lot four hundred and seventy-six \"A\" (P.476A) for the official plan and book of reference for the parish of Ste-Elisabeth, Joliette County, measuring sixty-two feet and a half at one end towards the south and fifty-five feet towards the north at the other end by one hundred and sixty feet in depth in its west line and one hundred and fifty-three feet in its east line, more or less, bounded as follows: in front by a private road of 25 feet width, at the other and towards the north by the land of L.Denobile and on both sides by B.Crevier. 196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10L' année, n° 2 Corporation municipale Notre-Dame-des-Prairies Municipal Corporation (cadastre de la paroisse de-of the parish of Saint-Charles-Borromée) Noms Names Descriptions Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Total Thery, Guy.:.Gariépy, Gilles.Lachapelle, Guy.Rainville, Mme Leopold.Râtelle, Albert.Chartier, Jean-Louis.Une partie du lot originaire 170 mesurant 85' de largeur par toute la profondeur qu'il y a entre le chemin public et le terrain de Réal Mousseau et borné comme suit: en front par le chemin public, d'un côté par le terrain d'Yvonne Deshaies, de l'autre côté par le terrain de Charles-Edouard Loyer et en arrière par le terrain de Réal Mousseau.Dufour, Gilles.Les bâtisses seulement érigées sur le lot 208 appartenant à Paul-Emile Asselin.Lafond, Arthur, failli.Une partie du lot originaire 110 mesurant 4 perches et 9 pieds en front et 100' en profondeur, borné en front par un chemin public entre le premier et le deuxième rang La Chaloupe, à l'arrière par partie 110.d'un côté au 109 et de l'autre côté au 111.Deschamps, Léo.Une partie du lot 206 mesurant 60' à un bout sur un chemin privé de 55' au bout opposé où il est borné par autre partie 206, 54' d'un côté oil il est borné à autre partie 206 et 65' de l'autre côté où il est borné a Gérard Lamarche.Bélanger, Jos-Maurice.Une partie du lot originaire 208 mesurant 116' en front et le long d'un chemin privé construit par P.-E.Asselin sur partie 208; dans la ligne d'un nommé P.-E.Golding, soit partie 20S, sur une longueur de 100' dans la troisième ligne venant avec ladite ligne du chemin privé ce terrain contient encore 166' de longueur.Lot No 201-13 St-Charles-Borromée 87-86.86-70.89-80.201-61,-62.S 2.87 S 17.22 S 20.09 167.07 36.33 203.40 587.77 429.96 1.017.73 264.63 626.21 890.84 10.29 10.29 47.12 201.58 248.60 A part of lot extracted of lot 170 measuring 85' in width by all the depth from the public road and the land of Real Mousseau and bounded as follows: in front by the public road, on one side by the land belonging to Yvonne Deshaies, on the other side by the land belonging to Charles-Edouard Loyer and in rear by the land of Real Mousseau.16.87 25.58 42.45 The buildings only on lot 208 belonging to Paul-É.Asselin.9.50 6.32 16.82 A part of land extracted from lot 110 measuring 4 and 9 feet in front and 100' in depth and bounded as follows: in front by the public road between the first and the second Range La Chaloupe, in rear by part of 110.on one side by lot No.109 and on the other side by lot No.111.40.39 59.88 100.27 A part of lot 206 measuring 60' at one end on a private road of 55' at the opposite end where bounded by other part of 206, 54' on one side where bounded by and other part of 206 and on the other side by G.Lamarche.32.30 96.62 128.92 A part of lot 208 measuring 116' in front and along a private road erected by P.E.Asselin on P.208, in the P.E.Golding line P.208.on a length of 100' feet in the third line coming with the private road where its measures 166' yet.Donné à Joliette, ce 5c jour de janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, 44001-2-2-o L.-Michel Hétu.Given at Joliette, this 5th day of January, 1972.L.-Michel Hetu, 44001-2-2-o Secretary-Treasurer.Municipalité! du Comte! de Papineau Avis public est par les présentes donné par le soussigné, CA.Montreuil, secrétaire-trésorier de la Corporation du Comté de Papineau, ayant son bureau et son domicile dans la municipalité du village de St-André-Avellin, P.Q.que les immeubles suivants seront vendus à l'enchère publique, en l'Hôtel de ville du village de Papineauvillc, P.Q.lieu où le conseil dudit Comté tient ses sessions, JEUDI le NEUVIÈME jour de MARS 1972 à DIX heures de l'avant-midi, pour les taxes municipales et scolaires et autres charges publiques dues aux Corporations ci-après énuraérées sur les divers lots de terrain ci-après désignés, à moins qu'elles ne me soient payées avec les frais avant la mise en vente.Municipality of the County of Papineau Public notice is hereby given by the undersigned, CA.Montreuil, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Papineau.having his office and domicile in the Municipality of the Village of St.André-Avellin.P.Q., that the following immovables will be sold by public auction, in the Village Chambers of the Village of Papineauvillr, P.Q., place where the council of the said County holds its meetings, on THURSD KY the NINTH day of MARCH, 1972, at TEN o'clock in the forenoon, for the municipal and school taxes, and public charges owing to the Corporations hereinafter listed, on the various lots of land hereinafter designated unless they are paid to me, together with the costs' before the sale. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol 10k, No.2 1117 Les commissaires d'écoles pour la municipalité (Prot.) de Buckingham The School Commissioners of the (Prot.) Municipality of Buckingham Montant Propriétaire Lot No Hang Canton dû Owner Lot No.Range Township Amount due Mme-Mrs.Stewart Yank.S.H 27 B.Une certaine pièce ou parcelle de terrain connue et désignée comme étant la moitié sud du lot numéro vingt-sept B (S.V2 27B) dans le rang six (Rg.VI) du cadastre officiel du canton de Lochaber, dans le comté de Papineau, mesurant cent vingt-cinq pieds (125') de largeur de l'est à l'ouest par cent vingt-neuf pieds (129') de profondeur du sud au nord, avec une maison dessus construite, membres et appartenances.Mlle-Mîiffl Adelaide O'Regan.P.31.Un immeuble situé à St-Pierre de Wakefield connu et désigné comme étant partie du lot numéro trente et un dans le troisième rang aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Portland Ouest, province de Québec, et décrit comme suit: borné au nord par le Lac St-Pierre de Wakefield, à l'ouest par la propriété de M.John Tomkievitz ou représentants, au sud par une route privée, propriété du vendeur, et à l'est par une autre partie dudit lot, appartenant au vendue, ladite parcelle de terrain mesurant cinquante pieds de largeur par la distance qui existe présentement entre le bord du Lac et la clôture de M.Tomkievitz ou.représentants, qui se trouve du côté ouest dudit lot; la limite sud dudit lot étant tracée en droite ligne avec la clôture de M.Tomkievitz et ladite propriété étant bornée comme suit au point situé du côté ouest de la propriété de M.Tomkievitz et du Lac, et mesure la distance qui existe entre le Lac et la propriété dudit Tomkievitz jusqu'à la clôture à l'arrière de ladite propriété et mesure de ce point en direction nord approximativement cinquante pieds en droite ligne avec ladite clôture, et en continuant le long de ladite clôture et de ce point tracé en ligne parallèle avec la propriété de M.Tomkievitz et à cinquante pieds de ladite limite ouest jusqu'au bord du Lac, et de ce point en direction sud jusqu'au point de départ et le long dudit Lac; Le tout tel qu'il existe présentement: .6.Lochaber.S 67.30 That certain piece or parcel of land known and designated as being the south-half of the lot number twenty-seven B (S.W 27B) in the sixth range (R.VI) of the official cadastre of the Township of Lochaber, in the county of Papineau, measuring one hundred and twenty-five feet (125') in width from east to west by one hundred and twenty-nine feet (129') in depth from south to north, with house thereon erected, members and appurtenances.3.Portland Ouest-West.121.08 An immoveable located at St.Pierre de Wakefield known and designated as being, part of lot number thirty-one in the Third Range for the Plan and Book of Reference of the Township of Portland West, Province of Québec, and described as follows: to the north by Lake St.Pierre de Wakefield, to the west by the property of Mr.John Tomkievitz or representative, to the south by a private road, property of the Vendor, and to the east by another part of said lot property of the Vendor, the said piece of land measuring fifty feet in width by the distance existing presently between the Lake Front and the fence of Mr.Tomkievitz or representative, located on the west side of the said lot; the south limit of the said lot being traced in straight line with the fence of Mr.Tomkievitz and the said property being bounded as follows at the point located on the west side of the property of Mr.Tomkievitz and the Lake, measure the distance existing between the Lake and the property of the said Tomkievitz to the fence at the back of the said property and from that point measure in the north direction approximately fifty feet in straight line with the said fence, and by continuing the said fence and from that point traced a parallel line with the property of Mr.Tomkievitz and at fifty feet from the said west limit, to the lake front, and from that point in direction south to the point of beginning and along the said Lake.The whole as it now exists: Les commissaires d'écoles pour la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix The School Commissioners of the Municipality of Notre-Dame-de-la-Paix Esse Gauthier.P.103, sub.du-of 646.Description: Partie est du lot 646-103.Paroisse de St-André-Avellin.de la contenance de 30 arpents de terre en superficie plus ou moins, et bornée h l'est par les terres du rang Thomas est, au nord par le lot 646-104, au sud par le lot 646-102 et vers l'ouest par le résidu dudit lot.lot ____ 8 6.19 Description: East part of lot 646-103, Parish of St.André-Avellin, containing 30 arpents of land, more or less, and bounded on the east by the farms of Thomas East Range, on the north by lot 646-104, on the south by lot 646-102 and towards the west by the remainder of the said lot.Corporation de la municipalité du Lac-Simon \u2014 Corporation of the Municipality of Lac-Simon Edouard Boyer.P.23.Désignation: Un terrain désigné au cadastre officiel pour le premier rang du canton d'Hartwell, sous partie du lot de terre numéro vingt-trois (P.23 R.1), mesurant, cinquante-sept pieds (57') dans la ligne ouest, deux cent soixante-cinq pieds (265') dans la ligne nord, deux cent quarante-cinq pieds (245') dans la ligne est et trois cent trente-neuf pieds (339') dans la ligne sud.Les mesures sont environ.Ce terrain est borné comme suit: Au nord par la propriété de Monsieur Marcelin Biais, à l'ouest le chemin public, à l'est la propriété de Monsieur Michel Lemée et au sud-ouest par la propriété de Monsieur Scryer.1.Hartwell.$ 19.46 Designation: A lot of land designated on the official cadastre for the first range of the Township of Hartwell, under part of lot of land number twenty-three (Pt.23 Rge.1) measuring, fifty-seven feet (57') in its west line, two hundred sixty-five feet (265') in its north line, two hundred forty-five feet (245') in its east line and three hundred thirty-nine feet (339') in its south line.The measures are approximate.This lot of land is bounded as follows: on the north by the property of Mr.Marcelin Biais, on the west by the public road, on the east by the property of Mr.Michel Lemée and on the southwest by the property of Mr.Scryer. I9S GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n' 2 Corporation de la municipalité du Lac-Simon (tuile) \u2014 Corporation of the Municipality of Lac-Simon (continued) Ce terrain est sujet au droit de passage en faveur du résidu dudit lot, propriété en partie de Monsiour Server et de Monsieur Michel Lemée pour le reste, tel que plus amplement décrit dans les titres d'acquisition des personnes plus haut mentionnées, droit de passage que l'acquéreur déclare connaître à sa satisfaction.This lot of land is subject to the right of way in favour of the remainder of the said lot, property in part of Mr.ocryer and of Mr.Michel Lemée for the remainder, as more fully described in the deeds of purchase of the aforementioned parties, right of way which the vendee declares to be known to him, to his satisfaction.Propriétaire\tLot No\tRang\tCanton »\tMontant dû Owner\tLot No\tRange\tTownship\tAmount due Ernest Desjardim» .P.33.Un emplacement, partie du lot numéro trente-trois, rang deux, au cadastre officiel du canton d'Hartwell (P.33.Rg.2).de \"5 pieds de largeur, sur 150 pieds de profondeur: borné à l'ouest par le sommet de la pente qui longe le ruisseau: au nord par le sommet de la pente qui longe le Lac Simon; vers l'est et vers le sud.par le résidu dudit lot, ci-devant propriété d'Arthur C.Lamert, aujourd'hui propriété de Léo Boucher; avec bâtisses.Comprenant aussi la partie dudit lot entre ledit emplacement et le Lac Simon, et le droit d'utiliser la grève dudit lac.Et avec droit de passage sur le résidu dudit lot.pour communiquer au chemin public.Le tout, tel que acquis par ventes enregistrées sous Nos.92504 et 100707.Stephan Ayoub.P.19B-P.19C.Désignation- Un terrain désigné au cadastre officiel pour le deuxième rang du canton d'Hartwell.sous partie des lots de terre numéro dix-neuf B et dix-neuf C (Pties 19B, 19C R.2).mesurant plus ou moins cent cinquante pieds (150') de largeur dans la ligne ouest et cent soixante-deux pieds (162') dans la ligne est, de façon à ce que le terrain ait cent cinquante pieds (150') de largeur dans la ligne nord-sud sur environ deux cent trente-deux pied» (232') dans la ligne sud et environ cent soixante-cinq pieds (165') dans la ligne nord soit la profondeur du terrain de M.Denis Bérard ou représentants et borné comme suit: Au nord la propriété de M.Denis Bérard ou représentants, à l'est et au sud la propriété de M.Rolland Marselais ou représentants, à l'ouest le lac.Avec bâtisses dessus construites.Servitude Avec droit de passage en commun et perpétuel, à pied et en voiture, au profit du terrain vendu pour circuler du terrain vendu à la voie publique, sur une langue de terre de douze pieds (12') de largeur faisant parties desdits lots et ayant pour longueur: 1° Du terrain vendu au chemin de la ferme soit sur une largeur de six cent trente-cinq pieds (635'ï.plus ou moins, lequel chemin pusse Hur l'extrémité est du terrain de Mlle Yolande Mousseau ou représentants droit de passage réservé à M.Rolland Marselais aux termes d'un acte de vente en date du 21 mai 1956 consenti par ledit Rolland Marselais à Mlle Yolande Mousseau; 2° sur le chemin de la ferme de M.Rolland Marselais pour se rendre à la voie publique.H art well.$77.70 An emplacement, part of lot number thirty-three, ranire two.on the official cadastre for the Township of Hartwell (Pt.33.Rge.2), 75 feet in width by 150 feet in depth ; bounded on the west by the summit of the slope that runs along the brook ; on the north by the summit of the slope that runs along Lac Simon; towards the east towards the south, by the remainder of the said lot, formerly the property of Arthur C.Lamert, now the property of Léo Boucher; with buildings.Comprising also the part of the said lot between the said emplacement and Lac Simon, and the right to use the shore of the said Lake.And with right of way on the remainder of the said lot, to communicate with the public highway.The whole, as acquired by sales registered under Nos.92504 and 100707.2.Hartwell.77.70 Designation: A lot of land designated on the official cadastre for the Township of Hartwell, under part of lots of land numbers nineteen B and nineteen C (Pts.19B, 19C Rge.2), measuring, more or less, one hundred fifty feet (150') in width in its west line and one hundred sixty-two feet (162') in its east line, so that the lot has one hundred fifty feet (150') in width in its north-south line by approximately two hundred thirty-two feet (232') in its south line and approximately one hundred sixty-five feet (165') in its north line, that is, the depth of the lot belonging to Mr.Denis Bérard or representatives and bounded as follows: on the north the property of Mr.Denis Bérard or representatives, on the east and south by the property of Mr.Rolland Marselais or representatives, on the west, the lake.With buildings constructed thereon.Servitude: With common and perpetual right of way, on foot or by vehicle, in favour of the sold lot of land, from the sold lot to the public highway, passing over a strip of land twelve feet (12') in width forming part of the said lots and extending in length: 1.From the sold lot to the farm road, that is.across a distance of six hundred thirty-five feet (635').more or less, which road passes at the east end of the lot of land belonging to Miss Yolande Mousseau or representatives, right of way reserved for Mr.Rolland Marselais under the terms of a deeel of sale dated May 21, 1956.authorized by the said Rolland Marselais, in favour of Miss Yolande Mousseau: 2.On the road of the farm belonging to Mr.Rolland Marselais.to communicate with the public highway.Corporation de la municipalité de Montpellier \u2014 Corporation of the Municipality of Montpellier Real St-Pierre.P.57.De la contenance de soixante pieds (00) de largeur eu front sur la Montée Lafontaine; sur cent vingt-neuf (129) piods de profondeur, plus ou moins, et tenunt en front au sud à la Montée qui conduit au Lac Schryer; à l'ouest à la partie dudit lot.propriété de Wilfrid Caron ou représentants; vers le nord à la partie du lot.propriété de Gérard Lalondeou représentants; vers l'est à la partie dudit lot restant la propriété de Joseph Viau.Sans bâtisse.7.Ripon.$ 29.96 Containmg swty feet (60) in width in front on Montée Lafontaine; by one hundred twenty-nine (129) feet in depth MW^TliSfe ™.d £°,rder'nJS Î\" front on the south on the Montée lead.ng to Schryer Lake; on the west on part of the said lot property of Wddnd Caron or representatives; towards P3r.1 °f lhAe lo,1- Property of Gérard Lalonde or representatives: towards the east on part of the said lot remaining the property of Joseph Vinu Without huildings. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol 104, No.2 199 Corporation de la municipalité de Montpellier (suite) \u2014 Corporation of the Municipality of Montpellier (continued) Propriétaire Lot No Owner Lot No.William Cliffin.P.13.Un terrain sis à Montpellier, désigné au cadastre officiel pour le sixième rang du canton d'Hartwell, sous partie du lot de terre numéro treize (13) rang six (6) canton d'Hartwell.Mesurant deux cent vingt pieds (220) de largeur, sur trois cent cinquante pieds (350) de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins.Ce terrain est borné comme suit: Au nord par te chemin public et des autres côtés par le résidu du lot.Ce terrain est situé à cent trente pieds (130) à l'est de la ligne de division entre les terres du rang six (6) et des terres du rang sept (7).Charles Orner Guimond.P.53.Un terrain désigné au cadastre officiel pour le neuvième rang (9) du canton de Ripon, sous partie du lot de terre numéro cinquante-trois (53) (Pte 53 R9R), mesurant deux cents pieds et deux dixièmes (200.2') dans la ligne nord en suivant la servitude de passage ci-après décrite, soixante-deux pieds et quatre dixièmes (62.4') dans la ligne est, deux cent deux pieds et trente-huit centièmes (202.38') dans la ligne sud, et soixante-trois pieds et deux dixièmes (63.2') dans la ligne ouest.Ce terrain est borné comme suit: en front au nord par la servitude de passage décrite audit acte, à l'est par la subdivision numéro cent (100), propriété de André Anderson, au sud par la partie du lot cinquante-deux (52) desdits rang et canton propriété de Jean-Paul Strasbourg, à l'ouest par le résidu dudit lot.Ce terrain est décrit plus en détail sur un plan projet dressé par Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre en date du 30 mai 1960 sous le numéro 1533 de ses minutes, comme étant les subdivisions non officielles numéro 98 et 99.Avec droit de passage.Mme-Mrs.Ghislaine Tardif.P.21.(épouse de-wife of Réjean Montpellier) Partie du lot vingt et un (21) rang cinq (5) canton Hartwell mesurant environ quatre vingt-dix (90) acres en superficie.À distraire dudit terrain les parties suivantes: a) la partie appartenant à T.N.V.R.Co.par actes enregistrés sous les numéros 38553 et 39468; b) la prtie occupée par Louis Groleau ou représentants (aujourd'hui acheté par adjudication pour taxes par M.François Groleau) ; c) La partie vendue à Marcel Charron par acte enregistré sous le numéro 86629; d) la partie vendue à François Groleau par acte de vente enregistré sous le numéro 88514; e) la partie vendue à François Groleau et Georges Racine par acte enregistré sous le numéro 94138; f) La partie vendue à Moïse Demers par acte enregistré sous le numéro 99834; g) La partie vendue à Dame Vve Ernest Massie par acte enregistré sous le numéro 100679; h) La partie vendue à Doris Giroux par acte enregistré sous le numéro 101505.Avec bâtisses.Servitude Hydro-Québec.Montant Rang Canton dû Range Township Amount due 6.Hartwell.$3.71 A lot of land situated in Montpellier, designated on the official cadastre for the Sixth Range of the Township of Hartwell, under part of lot of land number thirteen (13) Range Six (6) Township of Hartwell.Measuring two hundred twenty feet (220') in width, by three hundred hundred fifty feet (350') in depth, English measure and more or less.This lot of land is bounded as follows: On the north by the public road, and on the other sides by the remainder of the lot.This lot of land is situated one hundred thirty feet (130') east of the dividing line between the farms of Range Six (6) and those of Range Seven (7).9.Ripon.40.04 A lot of land designated on the official cadastre for the ninth Range (9) of the Township of Ripon, under part of lot of land number fifty-three (53) (Pt.53 R 9 R), measuring two hundred and two tenths feet (200.2') in its north line along the right of way described below, sixty-two and four tenths feet (62.4') in its east line, two hundred two and thirty-eight hundredths feet (202.38') in its south line, and sixty-three and two tenths feet (63.2') in its west line.This lot of land is bounded as follows: in front on the north by the right of way described in the said deed, on the east by subdivision number one hundred (100), property of André Anderson, on the south by that part of lot fifty-two (52) of the said Range and Township belonging to Jean-Paul Strasbourg, on the west by the remainder of the said lot.This lot of land is described in greater detail on a draft plan drawn up by Jean-Paul Alary, land-surveyor, dated May 30, 1960, under number 1533 of his minutes, as being unofficial subdivisions numbers 98 and 99.With right of way.5.Hartwell____.222.25 Part of lot twenty-one (21) Range Five (5) Township of Hartwell measuring approximately ninety (90) acres in area.To withdraw from the said lot the following parts: (a) the part belonging to T.N.V.R.Co.by deeds registered under numbers 38553 and 39468; (b) the part occupied by Louis Groleau or representatives (now bought by adjudication for taxes by Mr.François Groleau) ; (c) the part sold to Marcel Charron by deed registered under number 86629; (d) the part sold to François Groleau by deed of sale registered under number 88514; (e) the part sold to François Groleau and Georges Racine by deed registered under number 94138; (/) the part sold to Moïse Demers by deed registered under number 99834; (o) the part sold to Dame Ernest Massie, widow, by deed registered under number 100679; (h) the part sold to Doris Giroux by deed registered under number 101505.With buildings.Servitude Hydro-Québec.Corporation de la municipalité du canton de Notre-Dame-de-la-Salette Corporation of the Municipality of the Township of Notre-Dame-de-la-Salette Omer Binette.P.nord-north 27.Cette partie nord du lot 27 est située au nord du ruisseau à la Glaise passant sur ledit lot.et borné comme suit: au nord par la ligne de division entre les rangs 7 et 8 dudit canton, à l'est par partie du lot 26 rg.7 appartenant à Gérard Char-trand au sud et au sud-ouest, par le Ruisseau à la Glaise, et à l'ouest par le chemin conduisant au rang 8 dudit canton et séparant ledit lot 27 et le lot 28 tel qu'en fait l'acte enregistré le 26 décembre 1959 No 86582.7.Portland-Est-East (84 acres).$ 44.40 This north part of lot 27 is situated to the north of the Ruisseau à la Glaise flowing through the said lot, and bounded as follows: on the north by the dividing line between Ranges 7 and 8 of the said Township, on the east by part of lot 26 Rge.7 belonging to Gérard Chartrand, on the south and southwest, by the Ruisseau .à la Glaise, and on the west by the road leading to Range 8 of the said Township and separating the said lot 27 and lot 28 as effected in the deed registered on December 26, 1959, No.86582. 200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104e année, n*2 Corporation de la municipalité du canton de Notre-Dame-de-la-Salette (suite) Corporation of the Municipality of the Township of Notre-Dame-de-la-Salette (continued) Propriétaire Owner Lot No Lot No.Rang Range Canton Township Montant dû Amount due Omer Binette.26-27-28-29-30.Orner Binette.26-27-28-29.Marcel Laframboise.P.7.Un emplacement faisant partie du lot No 7 dans le 1er rang municipalité du Canton Notre-Dame-de-la-Salette.contenant en superficie une acre, et borné vers le nord et â l'est par un ruisseau, vers le sud par la route No 35 et vers l'ouest par ladite route No 35 et partie par le chemin du lac Thomas, avec bâtisses.> René Charette.1B-2A-P.2B.À distraire du lot 2B en faveur de Mme Nancy Wallingford une lisière de terrain de 250 pieds de large à partir de la rive du lac communément appelé lac Judge sur le coin du lot nord-ouest dudit lot 2B rang 1 dudit canton.Fidèle S t-Amour.P.4.Un emplacement faisant partie du lot No 4 dans le 5ième rang municipalité du Canton Notre-Dame-de-la-Salette.mesurant 90' de largeur sur 100' de profondeur, et borné vers le nord par un chemin ou ruelle, vers l'est par partie de la propiété de Monsieur Paul Dubé et des deux autres côtés par partie du môme lot avec bâtisses, à distraire une servitude de droit de passage du côté est pour communiquer au chemin public.9.Portland-Est-East (500 acres).$ 579.44 8.Portland-Est-East (400 acres).865.76 1.Portland-Est-East (1 acre).110.58 An emplacement forming part of lot No.7 in the first Range of the Municipality of the Township of Notre-Dame-de-la-Salette, containing one acre, and bounded towards the north and east by a brook, towards the south by Highway No.35 and part of Lac Thomas Road, with buildings.1.Portland-Est-East.645.53 To withdraw from lot 2B in favour of Mrs.Nancy Wallingford a strip of land 250 feet in width extending from the shore of the lake commonly known as Lac Judge on the corner of the lot northwest of said lot 2B Range 1 of the said Township.5.Portiand-Est-East (90' x 100') 168.14 An emplacement forming part of lot No.4 in the 5th Range-Municipality of the Township of Notre-Dame-de-la-Salette, measuring 90' in width by 100' in depth, and bounded towards the north by a road or lane, towards the east by part of the property of Mr.Paul Dubé and on the other two sides by part of the same lot with buildings, to withdraw a right of way on the east side communicating with the pu blic highway.Corporation de la municipalité de Ponsonby \u2014 Corporation of the Municipality of Ponsonby William Forget.24B.Ernest Forget.21B.Ewen Winfield.Sur-On lot 99.Un chalet (sans terrain) érigé sur le lot No 99, rang D.Canton de Ponsonby.Le lot sur lequel se situe ledit « chalet > est borné vers le nord par le lac Ponsonby \u2022 Wolf Lake North * vers l'est par le lot 9S du rang D, vers le sud par le rang D ou le lot 33A rang 3, vers l'ouest par le lot 100 du rang D.7.Ponsonbv (46 acres).$ 4.37 7.Ponsonby (47 acres).4.47 D.Ponsonby (Camp seul.-only).99.42 A cottage (without land) erected on lot No.99 Range D.Township of Ponsonby.The lot on which the said \"cottage\" is situated is bounded towards the north by Lac Ponsonby \"Wolf Lake North\" towards the east by lot 98 of Range D, towards the south by Range D or lot 33A Range 3, towards the west by lot 100 of Range D.Corporation de la municipalité de Suffolk & Addington Corporation of the Municipality of Suffolk and Addington Succession-Estate Oscar Rousson.P.33B.Un certain lopin de terre ou emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Suffolk, dans le cinquième rang sous partie du lot de terre numéro trente-trois-B (Ptie 33-b) mesurant soixante-dix pieds de largeur en front sur le chemin public, cent quinze pieds de profondeur dans la ligne nord, soixante-quatorze pieds de largeur dans la ligne de profondeur est.cent quarante-cinq pieds de profondeur, dans la ligne sud, et compris dans les bornes suivantes: En front vers l'ouest le chemin public route 57, vers le nord la partie dudit lot 33B, vendu à Monsieur Philias Thomas mesurant soixante-dix pieds de largeur en front sur le chemin public et vers le sud et vers l'est le résidu du lot propriété du vendeur.Ainsi que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives apparentes et occultes, attachés audit immeuble.5.Suffolk.S 7.87 A certain plot of ground or emplacement known and designated in the plan and book of reference of the official cadastre for the Township of Suffolk, in the fifth Range under part of lot of land number thirty-three B (Pt.33-b; measuring seventy feet in width in front on the public highway, one hundred fifteen feet in depth in its north line, seventy-four feet in width in its east line (depth), one hundred forty-five feet in depth in its south line, and enclosed by the following limits: In front towards the west the public Road Highway No.57, towards the north the part of said lot 33B, sold to Mr.Philias Thomas measuring seventy feet in width in front on the public road and towards the south and east by the remainder of the lot property of the vendor.As the whole now subsists, with all the active and passive, apparent and unapparent servitudes attached to the said immovable. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 201 Corporation de la municipalité de Suffolk & Addington (suite) Corporation of the Municipality of Suffolk and Addington (continued) Propriétaire Lot No Owner Lot No.Léo Pilon.% Sud-South-40.Un terrain désigné au cadastre officiel pour le sixième rang du canton de Suffolk, sous la moitié sud du lot numéro quarante ($4 S.40 R6) et compris dans les bornes suivantes: Vers le nord par la propriété de M.Orchestre Maurice ou représentants, en front par la concession du rang cinq d'un côté le lot 39 et de l'autre le lot 41.Avec cette vente est compris le droit de passage en faveur du terrain présentement vendu, sur le lot quarante du rang cinq dudit canton, tel que le présent vendeur l'a eu dans son titre d'acquisition.Marcel Drapeau.P.45.Xln lopin de terre faisant partie du lot connu et désigné comme étant le lot numéro quarante-cinq, du rang neuf (IX), du canton Addington, au cadastre dudit canton, comté Papineau, mesurant ce lopin de terre soixante-dix-huit pieds (78') en front au nord-est, sojxante-dix pieds (70') en arrière au sud-ouest sur toute la profondeur qu'il y a du chemin au Lac des Sucreries, soit environ cent pieds (100') de profondeur et borné au nord-est par ledit lac, au nord-ouest par l'emplacement appartenant à Dame Jeannine Desalliers, épouse de M.Jean Labonté en vertu de son titre dûment enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Papineauville sous le no 94576, au sud-ouest par le chemin privé ci-après mentionné, et au sud-est par l'emplacement vendu et appartenant à Louis Desalliers par l'acte enregistré sous le numéro 82901 ; Sans bâtisse et avec droit de passage dans le chemin privé du vendeur sur le résidu dudit lot quarante-cinq, et sur et à travers les lots quarante-six et quarante-sept, du même rang neuf, canton Addington, pour communiquer du chemin public au terrain vendu à charge par l'acquéreur de contribuer à l'entretien du chemin privé en commun avec les autres usagers et sans responsabilité de la part du vendeur pour dommages ou accidents pouvant survenir en utilisant ce chemin.Tel que le tout se trouve présentement que l'acquéreur déclare connaître et dont il se dit satisfait.Montant Rang Canton dû Range Township Amount due .6.Suffolk.$ 29.07 A lot of land designated on the office cadastre for the Sixth Range of the Township of Suffolk, under the south half of lot number forty (S.H 40 Rge.6) and contained within the following boundaries: Towards the north by the property of Orchestre Maurice or representatives, in front by the concession of Range Five, on one side by lot 39, and on the other by lot 41.The present sale comprises the right of way in favour of the land now sold on lot forty of Range Five of the said Township, such as the present vendor acquired it in his deed of purchase.9.Addington.21.19 A plot of land forming part of the lot known and designated as being lot number forty-five, of Range Nine (IX), of the Township of Addington.on the cadastre for the said Township.County of Papineau, measuring seventy-eight feet (78') in front on the northeast, seventy feet (70') in the rear on the southwest by the full distance (depth) between the road and the Lac des Sucreries, that is, approximately one hundred feet (100') in depth and bounded on the northeast by the said lake, on the northwest by the emplacement belonging to Dame Jeannine Desalliers, wife of Mr.Jean Labonté pursuant to his title duly registered in the Papineauville Division Registry Office under No.94576.on the southwest by the private road mentioned below, and on the southeast by the emplacement sold and belonging to Louis Desalliers by the deed registered under number 82901; Without buildings and with right of way on the vendor's private road, on the remainder of said lot forty-five, and on and across lots forty-six and forty-seven, for the said Range Nine, Township of Addington, communicating from the public road to the lot sold on condition that the vendee participate, with the other users, in the maintenance of the private road and without responsibility on the part of the vendor for damages or accidents that may arise as a result of using this road.As the whole now subsists, which the vendee declares to be to his knowledge and satisfaction.Godias Poitras.Sur-On lot No 49W.9.Addington.61.51 Est mise en vente la maison seulement, sise sur le terrain The house only is offered for sale, situated on the aforemen-précité possédé par M.Aurel Nantel.tioned lot owned by Mr.Aurel Nantel.Corporation de la municipalité de Vinoy \u2014 Corporation of the Municipality of Vinoy Mile-Miss Pauline Martel.P.11 (P.11-13) No 99,417, Vente: le 2 août 1964, par André Dufresne, notaire, enreg.le 25 août 1964, par Entreprises Namur Enreg.à Mlle Pauline Martel (1335 Triole Ottawa 15) de partie du lot 11, Rg 3, Canton de Suffolk, mesurant 50 de largeur sur 100 de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, bornée en front au nord-est la servitude de passage décrite audit acte, et des autres côtés par le résidu dudit lot, et au sud-ouest par une autre servitude de passage appelée rue.Subdivision non officielle, 11-13, avec droit de passage.Eloi Delorme.P.12 (P.12-39) No 99,161, Vente: le 7 juillet 1964.André Dufresne, notaire, enregistré le 29 juillet 1964, par les Entreprises Namur enregistré à Éloi Delorme (CP.264-C-F-B.Alouette Bagotville.P.Q.) de partie du lot 12, Rg., 3, Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, (Subdivision non officielle 39).Ce terrain est borné .3.Suffolk.* 103.00 No.99,417, Sale: On August 2, 1964, by André Dufresne.notary, registered August 25, 1964, by Entreprises Namur Enreg.to Miss Pauline Martel (1336 Triole Ottawa 15), part of lot 11, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, English measure, bounded in front on the northeast by the right of way described in the said deed, and on the other sides by the remainder of the said lot, and on the southwest by another right of way called a street.Unofficial subdivision, 11-13, with right of way.3.Suffolk.37.98 No.99,161, Sale: On July 7, 1964, André Dufresne, notary, registered on July 29, 1964, by Entreprises Namur Enreg., to Eloi Delorme, (P.O.Box 264, C-F-B.Alouette Bagotville.P.Q.) part of lot 12, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, English measure, (Unofficial subdivision 39).This lot of land is bounded in front GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.!.; janritr 1072, 10k- année, n° 2 Corporation de la municipalité de Vinoy (suite) \u2014 Corporation of the Municipality of Vinoy (con/inufd) en front au sud-ouest la servitude de passage décrite audit on the southwest (by) the right of way described in the said acte, et des autres côtés le résidu dudit lot, avec droit de deed, and on the other sides (by) the remainder of the said lot, passage.right of way.Montant Propriétaire Lot No Rang Canton dû Owner Lot No.Range Township Amount due Yvon Gravel.P.12 (P.12-112).3.Suffolk.$36.84 No99.166, Vente:le 17 juillet 1964, André Dufresne.notaire.No.99.166.Side: On July 17, 1964, André Dufresne, notary, enregistré le 29 juillet 1964, par les Entreprises Namur enregis- registered on July 29, 1964, by Entreprises Namur Enreg., to tré à Yvon Gravel.(245 Beech Wood, Village de Rockliffe, Yvon Gravel, of 245 Beech Word Village, of Rockliffe, Ont.Ont.) ou 245 Deech Wood Ave, Otluwa 2.) de partis du lot 12, or 245 Beech Wood Ave., Ottawa 2, part of lot 12, Range 3, Rg 3, Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, ce terrain more or less, English measure, this lot is bounded in front on est borné en front au nord-ouest la servitude de passage dé- the northwest (by) the right of way described in the said deed, crite audit acte, et des autres côtés par le résidu dudit lot, and on the other sides by the remainder of the said lot.(Unoffi- Subdivision non officielle 12-112, avec droit de passage.cial subdivision 12-112), with right of way RcalFortier.P.12 (P.12-108).No 99,170, vente; le 17 juillet 1964.André Dufresne.notaire, enreg.le 29.juillet 1964.par les Entreprises Namur Enreg.à Réal Fort ht (Gatineau 218 rue nord-ouest) de partie du lot 12, Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, ce terrain est borné en front au nord-ouest la servitude de passage audit acte, et des autres côtés par le résidu dudit lot (Subdivision non officielle 12-108) avec droit de passage.3.Suffolk.*.47.02 No.99.170.Sale: On July 17.1964.André Dufresne.notary, registered on July 29, 1964, by Entreprises Namur Enreg., to Réal Fortier (Gatineau.218 North-West Street) of part of lot 12.Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, English measure, this lot is bounded in front on the northwest (by) the right of way described in the said deed, and on the other sides by the remainder of the said lot.(Unofficial subdivision 12-108) with right of way.Maurice Valiquette.P.11 (P.11-142).99,572, vente; le 28 juillet 1964, André Dufresne.notaire, enreg.en septembre 1964, par Entreprises Namur Enreg., à Maurice Valiquette (303 Laçasse Eastview) de partie du iot 11, Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, ce terrain est borné en front au nord-ouest la servitude de passage décrite audit acte, et des autres côtés par le résidu dudit lot.(Subdivision non officielle 11-142.) aved droit de passage.3.Suffolk.47.37 99,572, Sale: On July 28, 1964.André Dufresne, notary, registered in September, 1964, by Entreprises Namur Enreg., to Maurice Valiquette (303 Laçasse.Eastview).part of lot 11.Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, English measure, this lot is bounded in front on the northwest (by) the right of way described in the said deed, and on the other sides by the remainder of the said lot.(Unofficial subdivision 11-142).with right of way.Raymond Dessurault.P.12 (P.12-167).No 101,187; le 3 mai 1965, Lucien Binette, notaire, enreg.le 6 mai 1965, à Raymond Dessureault, 86 rue St-Jacques.Hull, partie du lot 12, Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, et borné nu nord-ouest nord-est, et sud ouest par partie du même lot 12.et au sud-est, par un chemin privé, connue également comme 12-167, avec droit de passage.3.Suffolk.44.35 No.101.187.Sale: On May 3, 1965.Lucien Binet, notary, registered on May 6.1965, to Raymond Dessureault.85 St.Jacques Street, Hull, part of lot 12, Range 3, Township of Suffolk, mensunng 50' in width by 100' in depth, and bounded on the northwest, northeast and southwest by part of the same lot 12, and on the southeast, by a private road, also known as 12-167, with right of way.Gérard Gravelle.P.12 (P.12-30).No vente, 101.232; le 26 avril 1965.Lucien Binet.notaire, enreg.le 11 mai 1965 par les Entreprises Namur Enreg., à Gérard Gravelle (1130 Meadowlands Drive Apt 135 Ottawa) une partie du lot 12.Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100* de profondeur, et borné au nord-est, au sud-est et sud-ouest par partie du même lot 12, et au nord-ouest par un chemin privé, connu également comme 12-30, avec droit de passage.Suffolk.27.45 a part of lot 12 Range 3.Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100 in depth, and bounded on the northeast, on the southeast and southwest by part of the same lot 12.and on the northwest by a private road, also known as 12-30 with right of way.M.R.A.Patry.P.12 (P.12-74).No 101,017, vente: le 12 avril 1966, Lucien Binet.notaire, enreg., le 14 avril 1965, par les Entreprises Namur Enreg., à M.R.A.Patry, (105, rue Guigues apt., 1, Ottawa 3.) partie du lot 12.Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 60' de largeur par 100' de profondeur, borné au nord-ouest au nord-est et au sud-ouest par partie du même lot 12, te au sud-est par un chemin privé connu également comme 12-74.avec droit de passage.¦.3.Suffolk.40 M No.101,017, Sale: On April 12, 1965, Lucien Binet iWtarv registered on April 14, 1965, by Entreprises Namur Énree to M.R.A.Patry, (105 Guigues Street.Apt.1.Ottawa 3!iSrt of lot 12.Range 3.Township of Suffolk, measuring ày il width by 100 in depth, bounded on the northwest on the northeast and on the southwest by part of the same lot 12 and on the southeast by a private road also known as \\-> 74 with right of way.^ QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1973, Vol.lOi, No.3 203 Corporation de la municipalité de Vinoy (suite) \u2014 Corporation of the Municipality of Vinoy (continued) Propriétaire Owner Lot No Lot No.Rang Range Canton Township Montant dû Amount due Ernest Paquette.P.12 (P.12-59-12- No 100,866, vente; le 19 mars 1965, Lucien Binet, notaire, enreg.le 25 mars 1965, par Entreprises Namur Enreg., à Ernest Paquette, 1387, rue Marchand Cyrville, Ottawa 15, Ont., partie du lot 12, Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 100' de largeur par 100' de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, borné au nord-est, sud-ouest et nord-ouest par partie du même lot 12, et au sud-est par un chemin privé, avec droit de passage.Subdivision, P-12-59-12-60.Lionel Thibault.P.11 (P.11-140).Nu 101,841, vente, le 23 juillet 1900, Lucien Binet, notaire, enreg.le 23 juillet 1965, par Entreprises Namur Enreg., à Lionel Thibault (103 Armstrong, Ottawa 3,) partie du lot 11, Rg.3.Canton de Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, et borné au sud-ouest et au nord-est par partie du lot 11, et au sud-est par un chemin privé.Connu également comme le lot 11-140; avec droit de passage.Oscar-Léopold Tanguay.P.12 (P.12-62).No 102,490, vente; le 24 septembre 1965, Lucien Binet, notaire, enreg.le 28 septembre 1965, par les Entreprises Namur Enreg., a Oscar Leopold Tanguay, 59 Springhuerst, Ottawa, partie du lot 12, Rg.3.Canton Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, et borné au nord-ouest, au nord-est, et au sud-ouest par partie du même lot 12 et au sud-est par un chemin privé.Connu également comme 12-62.Ernest Cyr.,.P.11 (P.11-190).No 103,440.vente; le 9 février 1966, Lucien Binet, notaire, enreg.le 11 février 1966, par les Entreprises Namur Enreg., à Ernest Cyr, 490, Chamberlin Hawkesbury Ont.; partie du lot 11.Rg 3.Canton Suffolk, mesurant 50' de largeur par 100' de profondeur, et borné au nord par le lot 11-189; à l'est par partie du lot 11-181 ; au sud parle lot 11-191; et à l'ouest par un chemin privé.Subdivision 11-190.60) 3.Suffolk.g 52.39 No.100,866, Sale: On March 19, 1965, Lucien Binet, notary, registered on March 25, 1965, by Entreprises Namur Enreg., to Ernest Paquette, 1387 Marchand Street, Cyrville, Ottawa 15, Ont., part of lot 12, Range 3.Township of Suffolk, measuring 100' in width by 100' in depth, more or less, English measure, bounded on the northeast, southwest and northwest by part of the same lot 12, and on the southeast by a private road, with right of way.Subdivision, Pt.-12-59-12-60.3.Suffolk.33.26 No.101.841.Sale: On July 23.1905, Lucien Binet, notary, registered on July 23, 1965, by Entreprise Namur Enreg., to Lionel Thibault (103 Armstrong.Ottawa 3), part of lot 11, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, and bounded on the southwest, and on the northeast by part of lot 11, and on the southeast by a private road.Also known as lot 11-140; with right of way.3.Suffolk.36.84 No.102,490, Sale: On September 24, 1905, Lucien Binet, notary, registered on September 28.1965, by Entreprises Namur Enreg.to Oscar-Leopold Tanguay.59 Springhuerst, Ottawa, part of lot 12, Range 3.Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, and bounded on the northwest, on the northeast, and on the southwest by part of the same lot 12, and on the southeast by a private road.Also known as 12-62.3.Suffolk.40.54 No.103-440, Sale: On February 9, 1966, Lucien Binet, notary, registered on February 11, 1966, by Entreprises Namur Enreg., to Ernest Cyr.490 Chamberlin.Hawkesbury, Ont.; part of lot 11, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, and bounded on the north by lot 11-189; on the east by part of lot 11-181; on the south by lot 11-191; and on the west by a private road.Subdivision, 11-190.Mme-Mrs.Florence Lilian Wildsmith, veuve-widow C.Claude.P.11, P.12 (P.11 & 12-52).No 105,050, vente; le 14 septembre 1966, Lucien Binet, notaire, enreg.le 19 septembre 1966 par les Entreprises Namui Enreg., à Dame Florence Lilian Wildsmith, Vve de Claude Claude, demeurant à Ottawa 7,482, rue Lawson, partie des lots 11 et 12, Rang 3, Canton Suffolk.50x100, borné au nord-est par 12-53 et 11-3, au sud-est par un chemin privé; au sud-ouest par 12-51 et 11-1 et au nord-ouest par 11-5.Subdivision, p-11-2 et 12-52.(P-ll-2 et 12-52.) André Guérin.P.10 (P.10-50) No 105,371, vente; le 6 Octobre 1966, par Lucien Binet, notaire, enreg.le 20 octobre 1966, par les Entreprises Namur Enreg., à André Guérin, (20 .Monseigneur Forbes, Pte-Gati-neau) une partie du lot 10, Rg.3.Canton Suffolk (50x100) borné au nord par 10-51 à l'est par 10-36, au sud par 10-49, à l'ouest par un chemin privé.Subdivision 10-50.Jean-Claude Tourangeau.P.12 (P.12-414).No 106,864, vente; le 24 mai 1967, Lucien Binet, notaire, enreg.le 26 Mai 1967 par Eugène Lajeunesse < Entreprises Namur Enreg.», à Jean-Claude Tourangeau, (475, rue Abbot Hawkesbury, Ont.), de partie du lot 12, Rg.3.Canton Suffolk, mesurant 60' de largeur par 100' de profondeur, plus ou moins, mesures anglaises, et borné au nord-est par partie du lot 12, -2 .3.Suffolk.26.36 No.105,050, Sale: On September 14, 1966, Lucien Binet, notary, registered on September 19.1966, by Entreprises Namur Enreg., to Dame Florence Lilian Wildsmith, Widow of Claude Claude, residing at Ottawa 7,482 Lawson St.part of lots 11 and 12.Range 3.Township of Suffolk.50 x 100, bounded to the northeast by 12-53 and 11-3.to the southeast by'a private road; to the southwest by 12-51 and 11-1 and to the northwest by 11-5.Subdivision Pt.11-2, and 12-52.(Pt.-11-2 and 12-52.) .3.Suffolk.6.97 No.105,371, Sale: On October 6, 1966.by Lucien Binet, notary, registered on Octobf-r 20, 1966, by Entreprises Namur Enreg.to André Guérin, (20 Monseigneur Forbes, Pte-Gati-neau) a part of lot 10, Range 3.Township of Suffolk (50 x 100), bounded on the north by 10-51, on the east by 10-36, on the south by 10-49, on the west by a private road.Subdivision 10.50.3.Suffolk.48.57 No.106-864, Sale: On May 24, 1967, Lucien Binet, notary, registered on May 26, 1967 by Eugène Lajeunesse \"Entreprises Namur Enreg.\".to Jean-Claude Tourangeau, (475 Abbot Street, Hawkesbury.Ont.), of part of lot 12, Range 3, Township of Suffolk, measuring 60' in width by 100' in depth, more or less, English measure, and bounded on the northeast by 204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10A' année, n° 2 Corporation de la municipalité de Vinoy (suite) \u2014 Corporation of the Municipality of Vinoy (continued) au sud-est par la subdivision non officielle 415 du lot 12, au sud-ouest par un chemin privé de 25' et au nord-ouest par la subdivision non officielle 413 du lot 12, cet emplacement est connu comme lot originaire 12-414, avec droit de passage.part of lot 12, on the southeast by unofficial subdivision 415 of lot 12, on the southwest by a private road of \"25' and on the northwest by unofficial subdivision 413 of lot 12, this emplacement is known as original lot 12-414.With right of way.Propriétaire Owner Lot No Lot No.Rang Range Canton Township Montant dû Amount due Gilbert H.Paquette.P.10 (P.10-15).No 108,257, vente & dr.pass.: le 15 octobre 1967, André Dufresne, notaire, enreg.le 3 novembre 1967, par Dame Cécile Courval, Vve Roméo Raymond, à Gilbert-H.Paquette (5, Louis Crèse, Lucerne, Que.) de partie du lot 10, Kg.3.Canton Suffolk, mesurant 48' de largeur, sur 100' de profondeur, plus ou moins, et borné en front à l'ouest la servitude de passage, et des autres côtés par le résidu dudit lot, avec droit de passage.Subdivision No 10-15; .3.Suffolk.S 33.28 No.108.257, Sale and right of way: On October 15, 1967, André Dufresne, notary, registered on November 3, 1967, by Dame Cécile Courval, widow of Roméo Raymond, to Gilbert Paquette (5 Louis Crèse, Lucerne, Que.) of part of lot 10, Range 3.Township of Suffolk, measuring 48' in width by 100' in depth, more or less, and bounded in front on the west (by) the right of way, and on the other sides by the remainder of the said lot, with right of way.Subdivision.No.10-15.Georges Courie.P.10 (P.10-72).No 108,670, vente et dr.pass.; le 4 décembre 1967, André Dufresne, notaire, enreg.le 29 décembre 1967, par Dame Cécile Courval, épouse de Achille Villeneuve, à Georges Courie (55 Bryant Apt.18, Sherbrooke, Que.), de partie du lot 10, Rg.3.Canton Suffolk, mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, et borné en front à l'ouest la servitude de passage et des autres côtés par le résidu dudit lot, avec droit de passage.Subdivision No 10-72.3.Suffolk.27.45 No.108.670, Sale and right of way: On December 4, 1967, André Dufresne.notary, registered on December 29, 1967, by Dame Cécile Courval.wife of Achille Villeneuve, to Georges, Courie (55 Bryant, Apt.18.Sherbrooke, Que.) part of lot 10, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in.depth, more or less, and bounded in front on the west (by) the right of way, and on the other sides by the remainder of the said lot, with right of way Subdivision No.10-72.Marcel Gagnon.P.11 (P.11-45).No 108,622, vente et dr.pass.; le 4 décembre 1967, André Dufresne, notaire, enreg.le 20 décembre 1967, par Dame Achille Villeneuve (CécUe Courval) à Marcel Gagnon (74, rue Principale, Deschénes, Que.), de partie du lot 11, Rg.3.Canton Suffolk, mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, et borné en front au nord-ouest par la servitude de passage, et des autres côtés par le résidu dudit lot, avec droit de passage, Subdivision No 11-45.3.Suffolk.31.76 No.108,622, Sale and right of way: On December 4, 1967, André Dufresne, notary, registered on December 20, 1967, by Dame Achille Villeneuve, (Cécile Courval) to Marcel Gagnon, (74 Principale Street, Deschênes, Que.) part of lot 11, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, and bounded in front on the northwest by the right of way, and on the other sides by the remainder of the said lot, with right of way.Subdivision No.11-45.Jacques Barbeau.P.12 (P.12-91).No 108,624.vente et serv.; le 4 décembre 1967, André Dufresne, notaire, enreg.le 20 décembre 1967, par Dame Cécile Courval, épouse de Achille Villeneuve, a Jacques Barbeau (149, Ave Gondole.St-Eustache, paroisse), de partie du lot 12, Rg 3.Canton Suffolk, mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, et borné en front au sud-est par la servitude de passage et des autres côtés par le résidu dudit lot, avec le droit de passage.Subdivision No 12-91.3.Suffolk.31.76 No.108.624, Sale and Servitude: On December 4, 1967, André Dufresne, notary, registered on December 20, 1967, by Dame Cécile Courval, wife of Achille Villeneuve, to Jacques Barbeau, (149 Gondole Ave., St.Eustache Parish), part of lot 12, Range 3.Township of Suffolk, measuring 50' in width by 100' in depth, more or less, and bounded in front on the southeast by the right of way and on the other sides by the remainder of the said lot, with right of way.Subdivision No.12-91.Wilfrid Dubreuil.P.12 (P.12-38).No 109,342, vente et dr.pass.; le 25 Mars 1968, André Dufresne, notaire, enreg.le 18 avril 1968, par Dame Cécile Courval, épouse de Achille Villeneuve, à Wilfrid Dubreuil (St-Pascal, Ont.) de partie du lot 12, Rg.3.Canton Suffolk mesurant 50' de largeur sur 100' de profondeur, plus ou moins, et borné en front, au nord-ouest, par la servitude de passage et de3 autres côtés par le résidu dudit lot (Subdivision No 12-38), avec droit de passage.¦ 3.Suffolk.10.53 No.109.342, Sale and Right of wav: On March 25, 1968.André Dufresne, notary, registered on April 18, 1968, by Dame Cécile Courval, wife of Achille Villeneuve, to Wilfrid Dubreuil, (St.Pascal.Ont.) part of lot 12, Range 3, Township of Suffolk, measuring 50 in width by 100' in depth, more or less, and bounded in front, on the northwest, by the right of way, and on the other sides by the remainder of the said lot.(Subdivision No.12-38) with right of way.Donné à St-André-Avellin, P.Q., ce 3e jour de jan- Given at St-André-Avellin, P.Q., this 3rd dav of lanu- vier 1972.ary, 1972' Ae secrétaire-trésorier.Pi Montrfiiii 44008-2-2-o CA.Montheuil.44008-2-2 Secretary-Treasurer. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.lOi, No.2 205 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Holland Cadastre officiel de canton de Holland, municipalité de la Ville de Murdochville, division d'enregistrement de Gaspé Ouest.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 9-47 et que la partie restante des lots 9-91, 9-93 à 9-96 sont annulées en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 16 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Canton de Jonquiere Cadastre officiel de canton de Jonquiere, municipalité de la Cité de Jonquiere, division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 19A-49, 19A-50,19A-98à 19A-101, 19B-7 et 19B-11 du Rang IV sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 19 novembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Canton de Jonquiere Cadastre officiel de canton de Jonquiere, municipalité de la Cité de Jonquiere, division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que les lots 19A-79 et 19B-10 du Rang IV sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 19 novembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Paroisse de Laprairie de la Mugdcleine Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie de la Magdeleine, municipalité de la Ville de Brossard, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que la partie restante des lots 78-21 et 78-22 sont annulées en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 17 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-o Fernand Boutin.Canton de Letellier Cadastre officiel de Canton de Letellier, municipalité de la Cité de Sept-Iles, division d'enregistrement de Sept-Iles.Department of Lands and Forests Cadastre Township of Holland Official cadastre of township of Holland, municipality of Murdochville, Registration Division of Gaspé Ouest.Notice is hereby given that a part of lot 9-47 and that remaining part of lots 9-91, 9-93 to 9-96 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 16, 1971.Fernand Boutin, 43914-o Deputy Minister.Township of Jonquiere Official cadastre of township of Jonquiere, municipality of the City of Jonquiere, Registration Division of Chicoutimi.Notice is hereby given tjiat lots 19A-49, 19A-50, 19A-98 to 19A-101, 19B-7 and 19B-11 of Range IV are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, November 19, 1971.Fernand Boutin, 43914-o Deputy Minister.Township of Jonquiere Official cadastre of township of Jonquiere, municipality of the City of Jonquiere, Registration Division of Chicoutimi.Notice is hereby given that lots 19A-79 and 19B-10 of Range IV are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, November 19, 1971., Fernand Boutin, 43914-o Deputy Minister.Parish of Laprairie de la Magdeleine Official cadastre of the parish of Laprairie de la Magdeleine, municipality of the Town of Brossard, Registration Division of Laprairie.Notice is hereby given that remaining part of lots 78-21 and 78-22 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 17,1971.Fernand Boutin, 43914-0 Deputy Minister.Township of Letellier Official Cadastre of Township of Letellier, Municipality of the City of Sept-Iles, Registration Division, of Sept-Iles. 206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101' année, n° 2 Avis est par la présente donné que les lots 15-1, 15-2, 16-12 et 16-14 du Rang I sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 9 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Paroisse de Pointe-Claire Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, municipalité de la ville de Kirkland, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 155-21 et 155-22 sont annulés en vertu de l'article 2174A du ' Code civil.Québec, le 15 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Paroisse de Stc-Anne de la Pocatièrc Cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne de la Pocatiére, municipalité de la ville de La Pocatièrc, division d'enregistrement de Kamouraska.Avis est par la présente donné que les lots 168-40-16 à 168-40-18, 178-57-14, 178-57-15 et qu'une partie du lot 178-57-13 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 15 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-0 Fernand Boutin.Paroisse de St-Laurent Cadastre officiel de la paroisse de St-Laurent, municipalité de la ville de Montréal, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 2653 est ajouté et que les lots 330, 331, 331-1.331-2, 332, 332-1, 332-2, 333, 333-1, 333-2, 334, 334-1, 334-2, 335-6 à 335-14, 336-6 à 336-12, 336-16 à 336-21 et d'une partie des lots 313, 329, 335, 336, 340, 340-2 et 336-13 sont annulés en vertu de l'article 2174A du Code civil.Québec, le 14 décembre 1971.Le sous-ministre, 43914-o Fernand Boutin.Notice is hereby given that lots 15-1, 15-2, 16-12 and 16-14 of Range I are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 9, 1971.Fernand Boutin, 43914-0 Deputy Minister.Parish of Pointe-Claire Official cadastre of the parish of Pointe-Claire, municipality of the town of Kirkland, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 155-21 and 155-22 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 15, 1971.Fernand Boutin, 43914-0 Deputy Minister.Parish of Stc-Anne de la Pocatiére Official cadastre of the parish of Ste-Anne de la Pocatiére, municipality of the town of La Pocatiére, registration division of Kamouraska.Notice is hereby given that lots 168-40-16 to 168-40-18, 178-57-14, 178-57-15 and a part of lot 178-57-13 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Québec, December 15, 1971.Fernand Boutin, 43914-0 Deputy Minister.Parish of St-Laurent Official cadastre of the parish of St-Laurent, municipality of the town of Slontreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 2653 is added and that lots 330, 331, 331-1, 331-2, 332.332-1.332-2.333, 333-1, 333-2, 334, 334-1, 334-2, 335-6 to 335-14, 336-6 to 336-12, 336-16 to 336-21 and a part of lots 313, 329, 335, 336, 340, 340-2 and 336-13 are cancelled in virtue of Article 2174A of the Civil Code.Quebec, December 14, 1971.Fernand Boutin, 43914-o Deputy Minister.Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Applications for Surrender of Consol Investments Corp.\u2022 Avis est donné que la compagnie ¦ Consol Investments Corp.-, demandera au ministre des institutions, financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 30 décembre, 1971.Les procureurs de la compagnie, Greenberg, Goldsculeger 43919-0 & Blumenstein.Conxol Investments Corp.Notice is given that \"Consol Investments Corp.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, December 30, 1971.Greenberg, Goldschleger & Blumenstein, 43919-0 Attorneys for the Company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.101, No.2 207 Delta Services inc.Avis est donné que la compagnie \u2022 Delta Services inc.», corporation légalement constituée en vertu de la Loi des compagnies ayant son bureau chef dans la Cité de Sherbrooke, district de Saint-François, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, en conformité avec ladite Loi des compagnies.Sherbrooke, ce 17 décembre 1971.Les procureurs de la compagnie, 305-310 Continental, Blanchette & Roberge.Sherbrooke, Que.43920-o Delta Services inc.Notice is given that \"Delta Services inc.\", a corporation legally incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Sherbrooke, district of Saint-François, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the said Companies Act.Sherbrooke, December 17, 1971.Blanchette & Roberge, 305-310 Continental, Attorneys for the Company.Sherbrooke, Que.43920 I >i-1¦ 11¦ m.m,I Trading Ltd.Avis est par les présentes donné que « Drummond Trading Ltd.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 22e jour de décembre 1971.Le secrétaire, 43921-0 Marsiia Hocustadt.Drummond Trading Ltd.Notice is hereby given that \"Drummond Trading Ltd.\", a corporation incorporated under the Companies' Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 22nd day of December, 1971.Marsha Hochstadt, 43921-0 Secretary.Druna liivestnienl Corp.La compagnie « Druna Investment Corp.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions .financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 30e jour de décembre 1971.Les procureurs, 43922 Phillips, Vineberg, Phillips.Druna Investment Corp.Notice is hereby given that \"Druna Investment Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30th day of December, 1971 Phillips, Vineberg, Phillips, 43922-0 Attorneys.Flanders Equities Ltd.La compagnie « Flanders Equities Ltd.», donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 30e jour de décembre 1971.Les procureurs de la compagnie, Greenberg, Coluschleger 43923 & Blumenstein.Flanders Equities Ltd.Notice is given that \"Flanders Equities Ltd.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 30th day of December, 1971.Greenberg, Goldschleger & Blumenstein, 43923-0 Attorneys for the Company.Drummond Speedway Avis est donné que la compagnie « Drummond Speedway » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Drummond ville, le 16 décembre 1971.Le procureur de la compagnie, 43995-0 Me Paul Chassé, avocat.Drummond Speedway Notice is given that \"Drummond Speedway\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Drummondville, December 16, 1971.Paul Chassé, Advocate, 43995 Attorney for the Company. 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 197S, 10J,' année, n° S Plurimar inc.La compagnie « Plurimar inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire-trésorier, Danielle Chalifoux-De Brouwer.43998-0 715186 J.Caplan and Co.Ltd.La compagnie « J.Caplan and Co.Ltd.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec et ayant son siège social en la ville de Montréal, province de Québec, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté en la cité de Montréal, province de Québec, ce 14e jour de décembre 1971.Le vice-président, 43994 Oscar Weinstein.Les Entreprises Fleury inc.Avis est donné que la compagnie « Les Entreprises Fleury inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur, 43996-0 Me Claude Gratton.Plurimar inc.Notice is given that \"Plurimar inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Danielle Chalifoux-De Brouwer, Secretary-Treasurer.43998 715186 J.Caplan and Co.Ltd.Notice is hereby given that \"J.Caplan and Co.Ltd.\", a corporation incorporated under the Québec Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Québec Companies Act.Dated at the city of Montreal, Province of Québec, this 14th day of December, 1971.Oscar Weinstein, 43994-0 Vice-President.Les Entreprises Fleur> inc.Notice is given that \"Les Entreprises Fleury inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me Claude Gratton, 43996 Attorney.Lafayette Shoe Manufacturing Company Limited Lafayette Shoe Manufacturing Company Limited Avis est par les présentes donné que la compagnie « Lafayette Shoe Manufacturing Company Limited » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, 3 décembre 1971.L'assistant-secrétaire, 43929-0 D.G.Sutherland.The Montreal Cotton Company La compagnie « The Montreal Cotton Company » donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, Québec, le 16 décembre 1971.Le secrétaire, 43930-o C.M.Beck.S.J.Rawin Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « S.J.Rawin Ltd.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner 'sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 28e jour de décembre 1971.(Sceau) Le secrétaire, 43932-0 Dorothy Rawin.Notice is hereby given that \"Lafayette Shoe Manufacturing Company Limited\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 3, 1971.D.G.Sutherland, 43929-0 Assistant Secretary.The Montreal Cotton Company Notice is given that \"The Montreal Cotton Company\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montreal, Québec, December 16, 1971.C.M.Beck, 43930-o Secretary.S.J.Rawin Ltd.Notice is hereby given that \"S.J.Rawin Ltd.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 28th day of December, 1971.(Seal) Dorothy Rawin, «932-0 Secretary. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 1972, Vol.104, No.2 209 Swan Cleaners Inc.Nettoyeurs Swan Inc.Avis est par les présentes donné que « Swan Cleaners Inc.\u2014 Nettoyeurs Swan Inc.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la Cité de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 23e jour de décembre 1971.Le secrétaire, 43931-0 Edouard Lalumière.Swan Cleaners Inc.Nettoyeurs Swan Inc.Notice is hereby given that \"Swan Cleaners Inc.\u2014 Nettoyeurs Swan Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 23rd day of December, 1971.Edouard Lalumiere, 43931-0 Secretary.Ronmur Slacks Ltd.La compagnie ' Ronmur Slacks Ltd.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes datées du 11 novembre 1970, et ayant son siège social à Montréal, donne avis qu'elle a établi son bureau au 135, avenue Van Home, en les ville et district de Montréal.Montréal, 6 décembre 1971.Ronmur Slacks Ltd., (Sceau) Le secrétaire, Ronald Robinson.43933 4927-70 Fonds Richelieu inc.Avis est par la présente donné, que « Fonds Richelieu inc.», une compagnie incorporée sous la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à St-Hyacinthe, présentera une requête au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à St-Hvacinthe, ce 27e jour de décembre 1971.Le secrétaire, 43924-0 Roger St-Germain.Ronmur Slacks Ltd.Notice is hereby given that \"Ronmur Slacks Ltd.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated November 11, 1970, and having its head office in Montreal, has established its office at 135 Van Home Avenue, in the city and district of Montreal.Montreal, December 6, 1971.Ronmur Slacks Ltd., (Seal) Ronald Robinson, Secretary.43933-0 4927-70 Fonds Richelieu inc.Notice is hereby given that \"Fonds Richelieu inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at St.Hyacinthe, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at St-Hyacinthe, this 27th day of December 1971.Roger St-Germain, 43924-0 Secretary.Foyer Bourbonnais Inc.Avis est donné que la corporation « Foyer Bourbonnais Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Donné à Rouyn, ce 28e jour de décembre 1971.Les procureurs de la corporation, 43925-0 Coutu & Coutu.Foyer Bourbonnais Inc.Notice is given that the corporation \"Foyer Bourbonnais Inc.\" will ask to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the permission to surrender his charter.Given at Rouyn, this 28th of December 1971.Coutu & Coutu, 43925-0 Attorneys for Corporation.L & W Realties Ltd.Avis est par les présentes donné que « L & W Realties Ltd.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte pour annulation.Montréal.P.Q.le 23 décembre 1971.(Sceau) Le secrétaire, 43928-0 P.F.Renaud.L & W Realties Ltd.Notice is hereby given that \"L & W Realties Ltd.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, P.Q., December 23, 1971.(Seal) P.F.Renaud, 43928-0 Secretary. 210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10h' année, n° S Ili-Quality Construction Inc.La compagnie « Hi-Quality Construction Inc.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de Québec, et ayant son siège social à Montréal, Québec, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 24e jour de décembre 1971.Les procureurs de la compagnie, Kaufman, Respitz, Sf.deroff 43926 & Shugar.Ili-Quality Construction Inc.Notice is given that \"Hi-Quality Construction Inc.\", a company incorporated under the Québec Companies Act.and having its head office at Montreal.Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of December, 1971.Kaufman, Respitz, Sederoff & Shucar, 43926-0 Attorneys for Company.Hunter Douglas Limited Avis est par les présentes donné que « Hunter Douglas Limited», compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la cité de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 24e jour de décembre 1971.Le secrétaire, 43927-o John Lotuar Bruhl.Ross Investment Corp.Avis est donné que la compagnie « Ross Investment Corp.\u2022 demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 30 décembre 1971.Les procureurs de la compagnie, Greenberg, Goldschlegeh 43934-0 & 1îlumenstein.Ruby Foo's Farm Inc.Avis est par les présentes, donné que la compagnie « Ruby Foo's Farm Inc.constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 28 décembre 1971.(Sceau) Les procureurs de la compagnie, 43935-o Robinson, Sheppard & Shapiro.H.Auger Welding Co.Ltd.La compagnie « H.Auger Welding Co.Ltd.» donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 43937 Saul Handelman.Hunter Douglas Limited Notice is hereby given that \"'Hunter Douglas Limited\", a company incorporated under the Companies Act having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of December, 1971.John Lothar Bruhl, 43927-o Secretary.Ross Investment Corp.Notice is given that \"Ross Investment Corp.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quél>ec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 30th day of December, 1971.Greenberg, Goldschleger & Blumenstein, 43934-0 Attorneys for the Company.Kuby Foo's Farm Inc.Notice is hereby given that \"Ruby Foo's Farm Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 28th day of December 1971.(Seal) Robinson, Sheppard & Shapiro, 43935-0 Attorneys for the Company.II.Auger Welding Co.Ltd.Notice is hereby given that \"H.Auger Welding Co.Ltd.\" will make an application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Saul Handei.man, 43937-o Attorney for the Company. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 211 Sunset Investment Corp.Avis est par les présentes, donné que la compagnie « Sunset Investment Corp.», constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la cité de Montréal s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 30 décembre 1971.Les procureurs de la compagnie, 43936-0 Robinson, Siibppard & Shapiro.Sunset Investment Corp.Notice is hereby given that \"Sunset Investment Corp.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the city of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30th day of December 1971.Robinson, Sheppard & Shapiro, 43936-0 Attorneys for the Company.Divers Compagnies Miscellaneous Compagnies Expert Candy Ltd.Le Bonbon Expert ltée La compagnie « Expert Candy Ltd.\u2014 Le Bonbon Expert ltée » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 6 le nombre de ses administrateurs.L'assistant-secrétaire, F.A.Cheftechi.43941 10032-58 Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 26 juillet 1971, il a approuvé les règlements généraux de la corporation » Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.43944-0 499-71 Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.La corporation « Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 9.Le secrétaire, Mme Delia E.Blanchard.43944-u 499-71 Placements Grenache inc.Sommaire du règlement spécial « 1971-A » Le règlement spécial « 1971-A» adopté le 21 décembre 1971 par les administrateurs de « Placements Grenache inc.» et ratifié par les actionnaires le même jour pourvoit à la distribution de tout l'actif et de tous les biens de la compagnie au prorata entre ses actionnaires quinze jours après la publication du présent sommaire du règlement « 1971-A » dans la Gazette officielle de Québec.Montréal, ce 21e jour de décembre 1971.(Sceau) Le secrétaire, 43997-0 Pierre Grenache.Expert Candy Ltd.Le Bonbon Expert ltée Notice is given that \"Expert Candy Ltd.\u2014 Le Bonbon Expert ltée\" has changed the number of its directors from 3 to 6.F.A.Cheftechi, Assistant Secretary.43941-0 10032-58 Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on July 26, 1971, pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved the general by-laws of \"Club de l'Age d'Or de Waterloo inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43944 499-71 Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.Notice is given that \"Club de l'Âge d'Or de Waterloo inc.\" has increased the number of its directors from 4 to 9.Mrs.Delia E.Blanchard, Secretary.43944 499-71 Placements Grenache inc.Summary of Special By-law \"1971-A\" The special by-law \"1971-A\" adopted on December 21, 1971 by the directors of \"Placements Grenache inc.\" and ratified by the shareholders on the same date provides for the distribution of all the assets of the company among its shareholders in proportion to the number of shares they hold thereof fifteen days after the publication of the present summary of by-law \"1971-A\" in the Québec Official Gazette.Montreal, this 21st day of December 1971.(Seal) Pierre Grenache, 43997-0 Secretary. 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 janvier 197S, 104e année, n° S Alamo Electric Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 23, de la compagnie « Marsh Interests Inc.», constituée par lettres patentes en date du lie jour de février 1959, changeant son nom en celui de « Alamo Electric Ltd.».Le directeur du service des compagnies, Rocii Rioux.43940-O 10748-59 Centre d'Accueil Lauren lien La ' corporation « Centre d'Accueil Laurentien » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 6.Le secrétaire, Paule Gauthier.43942-o 714274 Création Prothèse Capillaire ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement de la compagnie « Création Pro-Cap ltée».constituée par lettres patentes en date du 22e jour de février 1971, changeant son nom en celui de « Création Prothèse Capillaire ltée ».Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.43945-0 863-71 École de Natation Régent Lacoursière inc.Régent Lacoursière Swim School Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro « A », de la compagnie « Promotions Sports Nautiques inc.», constituée par lettres patentes en date du 16e jour de novembre 1966, changeant son nom en celui de « École de Natation Régent Lacoursière inc.\u2014 Régent Lacoursière Swim School Inc.».Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.43946-o 4692-66 Éditions Vaudreuil inc.La compagnie « Éditions Vaudreuil inc.-\" donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Gilles Charbonneau.43947-0 3753-65 Jean-Paul Gratton inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 5, de la compagnie « Gratton, Saucier & Associés inc.», constituée par lettres patentes en date du 30e jour de juillet 1970, changeant son nom en celui de « Jean-Paul Gratton inc.».Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.43948-0 .3345-70 Alamo Electric Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.23, of the company \"Marsh Interests Inc.\", incorporated by letters patent dated the 11th day of February, 1959, changing its name into that of \"Alamo Electric Ltd.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43940-o 10748-59 Centre d'Accueil Laurentien Notice is given that \"Centre d'Accueil Laurentien\" has increased the number of its directors from 5 to 6.43942 Paule Gauthier, Secretary.714274 Création Prothèse Capillaire ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law of the company \"Création Pro-Cap ltée\", incorporated by letters patent dated the 22nd day of February 1971, changing its name into that of \"Création Prothèse Capillaire ltée\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43945-0 863-71 Ecole de Natation Régent Lacoursière inc.Régent Lacoursière Swim School Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number \"A\", of the company \"Promotions Sports Nautiques inc.\", incorporated by letters patent dated the 16th day of November, 1966, changing its name into that of \"École de Natation Régent Lacoursière inc.\u2014 Régent Lacoursière Swim School Inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43946-o 4692-66 Éditions Vaudreuil inc.Notice is given that \"Éditions Vaudreuil inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Gilles Charbonneau, Secretary.43947 3753.65 Jean-Paul Gratton inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law number 5, of the company \"Gratton, Saucier & Associés inc.\", incorporated by letters patent dated the 30th day of July, 1970, changing its name into that of \"Jean-Paul Gratton inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43948-° 3345-70 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 213- Head & Hands Inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 20 décembre 1971, il a approuvé les règlements de la corporation « Head & Hands Inc.», et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43949-0 714661 Head & Hands Inc.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 20, 1971, and pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved the by-laws of the corporation \"Head & Hands Inc.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43949 714661 Les Industries Val Mar inc.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives doDne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 10, de la compagnie « Eugène Roy limitée \u2014 Eugène Roy Limited », constituée par lettres patentes en date du 17e jour de décembre 1954, changeant son nom en celui de « Les Industries Val Mar inc.».Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.43950-o 13094-54 Intcr-Ex inc.La compagnie « Inter-Ex inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Louise Bouchard.43951-e 1568-68 Les Industries Val Mar Inc.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.10, of the company \"Eugène Roy limitée ¦\u2014 Eugène Roy Limited\", incorporated by letters patent dated the 17th day of December, 1954, changing its name into that of \"Les Industries Val Mar inc.\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43950-o 13094-54 Inter-Ex inc.Notice is given that \"Inter-Ex inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Louise Bouchard, Secretary.43951 1568-68 Quality Book Distributors Ltd.Librairie Qualité ltée Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 22, de la compagnie « Quality Book Distributors Ltd.\u2014 Distributeurs de Livres de Qualité ltée », constituée par lettres patentes en date du 21e jour d'avril 1965, changeant son nom en celui de « Quality Book Distributors Ltd.\u2014 Librairie Qualité ltée».Le directeur du service des compagnies, Roch Rioux.43952-o 1879-65 McGuire Press Co.Limited La compagnie « McGuire Press Co.Limited » donne avis qu'elle diminué a de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, Issie Engel.43954 10924-61 O'Brien Gold Mines, Limited (No personal liability) La compagnie « O'Brien Gold Mines, Limited (No personal liability) » donne avis qu'elle a diminué de 7 à 6 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, R.W.Cuisholm.43955 1791-34 Quality Book Distributors Ltd.Librairie Qualité ltée Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.22, of the company \"Quality Book Distributors Ltd.\u2014 Distributeurs de Livres de Qualité ltée\", incorporated by letters patent dated the 21st day of April, 1965, changing its name into that of \"Quality Book Distributors Ltd.-\u2014Librairie Qualité ltée\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43952-0 1879-65 McGuire Press Co.Limited Notice is given that \"McGuire Press Co.Limited\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Issie Engel, Secretary-Treasurer.43954-0 10924-61 O'Brien Gold Mines, Limited (No personal liability) Notice is given that \"O'Brien Gold Mines, Limited (No personal liability)\" has changed the number of its directors from 7 to 6.R.W.Chisholm, Secretary-Treasurer.43955-0 1791-34 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1972, 104\" année, n' 2 Marwest Hotel Company Ltd.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement numéro 12A, de la compagnie « Western International Hotels Inc.\u2014-Les Hôtels Internationaux de l'Ouest inc.», constituée par lettres patentes en date du 17e jour de mai 1966, changeant son nom en celui de « Marwest Hotel Company Ltd.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.43953-0 2095-66 The Ottawa Ski Club, Incorporated Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 16 décembre 1971, il a approuvé les règlements B et C de la corporation « The Ottawa Ski Club, Incorporated », et ce, en vertu de l'article 225 de la Loi des compagnies.Le directeur du service des compagnies, Rocu Rioux.43956-0 1624-21 Plant National Industries (Canada) Ltd.La compagnie « Plant National Industries (Canada) Ltd.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, I.Cohen.43957 5769-70 Plant National Industries (Montreal) Ltd.La compagnie \"Plant National Industries (Montreal) Ltd.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, I.Cohen.43958 7561-45 Prographis Inc.La compagnie « Prographis Inc.» donne avis qu'elle a diminué de 5 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Mary Lentgis.43959 16298-59 Les Résidences de la Mauricie inc.La corporation « Les Résidences de la Mauricie inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 16 à 9.Le secrétaire, Huguktte Landry.43960-o 825-71 Rivière-du-Loup Câble T.V.liée La compagnie « Rivière-du-Loup Câble T.V.ltée » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.' Le secrétaire, Grégoire Thibault.43961-0 4154-68 Marwest Hotel Company Ltd.Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law No.12A, of the company \"Western International Hotels Inc.\u2014 Les Hôtels Internationaux de l'Ouest inc.\", incorporated by letters patent dated the 17th day of May, 1966, changing its name into that of \"Marwest Hotel Company Ltd.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.43953-0 2095-66 The Ottawa Ski Club.Incorporated The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 16, 1971, and pursuant to section 225 of the Companies Act, he approved by-laws B and C of \"The Ottawa Ski Club, Incorporated\".Roch Rioux, Director of the Companies Service.43956 1624-21 Plant National Industries (Canada) Ltd.Notice is given that \"Plant National Industries (Canada) Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.I.Cohen, Secretary.43957-0 5769-70 Plant National Industries (Montreal) Ltd.Notice is given that \"Plant National Industries (Montreal) Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.I.Cohen, Secretary.43958-0 7561-45 Prographis lac.Notice is given that \"Prographis Inc.\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Mary Lentgis, Secretary.43959-0 16298-59 l.es Residences de la Mauricie inc.Notice is given that \"Les Résidences de la Mauricie inc.\" has decreased the number of its directors from 16 to 9.Huguette Landry, .,\u201e\u201e.Secretary.43960 825.y, Rivière-du-Loup Câble T.V.ltée Notice is given that \"Rivière-du-Loup Câble TV ltée\" has increased the number of its directors from 3 to o.Grégoire Thibault, Secretary.UJbl 4154-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 215 Sièges sociaux Head Offices Quality Book Distributors Ltd.Distributeurs de Livres de Qualité ltée.Avis est donné que la compagnie « Quality Hook Distributors Ltd.\u2014 Distributeurs de Livres de Qualité ltée », constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 avril 1965 et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'à la date d'aujourd'hui au 1231 ouest, rue Ste-Catherine, l'a transporté à 260 ouest, rue Faillon, Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 1er décembre 1971.(Sceau) Le secrétaire, 43966-o Daniel Wainberg.Dubreuil - Lefebvre - Roy inc.La compagnie « Dubreuil - Lefebvre - Roy inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Cap-de-la-Madeleine, au numéro 385, rue Sherbrooke est, Montréal.Le secrétaire, Audrey S.Lefebvre.43967-o 122-65 Entreprises Ginelain inc.La compagnie» Entreprises Ginelain inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Chambord, au numéro 1245, rue Borne, Québec.Le secrétaire, Ginette Gagnon.43968 3344-71 Fédération des Écoles privées de la province de Québec inc.Federation of Private Schools of the Province of Québec Inc.Avis est donné que la compagnie « Fédération des Écoles privées de la province de Québec inc.\u2014 Federation of Private Schools of the Province of Québec Inc.», constituée en corporation en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies en date du 3 avril 1967 et ayant son siège social à Montréal, où elle avait son bureau situé au 1600, rue Berri, l'a transporté au 3155, de la rue Hochelaga.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce lie jour de février 1971.(Sceau) Jean Meunier.43969-0 Inter-Ex Inc.La compagnie « Inter-Ex inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Westmount au numéro 2551, Chemin St-Louis, Sillery.Le secrétaire, Louise Bouchard.43951-0 1568-68 Quality Book Distributors Ltd.Distributeurs de Livres de Qualité ltée.Notice is given that \"Quality Hook Distributors Ltd.\u2014 Distributeurs de Livres de Qualité ltée\", incorporated by letters patent on April 21, 1965, and having its head office in the city of Montreal, where its office was situated up to to-day at 1231 St.Catherine Street West, has moved it to 260 Faillon Street West, Montreal.From the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, December 1, 1971.(Seal) Daniel Wainberc, 43966 Secretary.Dubreuil - Lefebvre - Roy inc.Notice is given that \"Dubreuil - Lefebvre - Roy inc.\" has transferred its head office from Cap-de-la-Madeleine to 385 Sherbrooke Street East, Montreal.Audrey S.Lefebvre, Secretary.43967 122-65 Entreprises Ginelain inc.Notice is given that \"Entreprises Ginelain inc.\" has transferred its head office from Chambord to 1245 Borne Street.Québec.Ginette Gagnon, Secretary.43968-0 3344-71 Fédération des Écoles privées de la province de Québec inc.Federation of Private Schools of the Province of Québec Inc.Notice is given that \"Fédération des Écoles privées de la province de Québec inc.\u2014 Federation of Private Schools of the Province of Québec Inc.\", incorporated under Part III of the Companies Act on April 3, 1967, and having its head office in Montreal, where its office was situated at 1600 Berri Street, has moved it to 3155 Hochelaga Street.From the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 11th day of February, 1971.(Seal) Jean Meunier.43969 Inter-Ex Inc.Notice is given that \"Inter-Ex inc.\" has transferred its head office from Westmount to number 2551 St.Louis Road, Sillery.Louise Bouchard, Secretary.43951 1568-68 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 104' année, n° S Beaton-Saulnier Inc.Avis est donné que la compagnie « Beaton-Saulnier Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 5e jour de mai 1971, et ayant son siège social à Lachutc, a établi son bureau au numéro 540, rue Principale.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Lachute, ce 18e jour d'octobre 1971.DONAT SaULNIER.43962-0 2639-71 Beaton-Saulnier Inc.Notice is given that \"Beaton-Saulnier Inc.\" incorporated by letters patent dated the 5th day of May 1971, and having its head office in Lachute, has established its office at number 540 Main Street.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Lachute, this 18th day of October 1971.DONAT SAULNIER.43962 2639-71 Contractors Supplies Limited La compagnie « Contractors Supplies Limited » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1950, boulevard Sir Wilfrid Laurier, Laflèche, au numéro 335, Chemin Côte Saint-Louis, Blainville.Le secrétaire, Bernard Sicotte.43963 9519-49 Contractors Supplies Limited Notice is given that \"Contractors Supplies Limited\" has transferred its head office from 1950 Sir Wilfrid Laurier Boulevard, Lafièche, to 335 Chemin Côte Saint-Louis, Blainville.Bernard Sicotte, Secretary.43963-0 9519-49 R.Dandurand & associés inc.Avis est donné que la compagnie « R.Dandurand & associés inc.» constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec, le 29 octobre 1971 et ayant son siège social en la cité de Grand'Mère, a établi son bureau au 350, 5e Avenue, Grand'Mère, district de St-Maurice, dans la province de Québec.Daté à Grand'Mère.ce 2e jour de décembre 1971.Le secrétaire, Guy Rinfret.43964-0 715786 Daigle Aqua inc.La compagnie « Daigle Aqua inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Cowansville, au numéro 1369, boidevard Ste-Foy, Longueuil.Le.secrétaire, G.Gordon Kohl.43965-0 16426-59 R.Dandurand & associés inc.Notice is hereby given that \"R.Dandurand & associés inc.\" incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Québec Companies Act, on October 29, 1971, and having its head office in the city of Grand'Mère, has established its office at 350.5th Avenue in Grand'Mère, district of St-Maurice, Province of Québec.Dated at Grand'Mère.this 2nd day of December 1971.Guy Rinfret, Secretary.43964-0 715786 Daigle Aqua inc.Notice is given that \"Daigle Aqua inc.\" has transferred its head office from Cowansville to number 1369 St.Foy Boulevard, Longueuil.G.Gordon Kohl, Secretary.43965 16426-59 La Société des consultants en administration hospitalière ltée Avis est donné que la compagnie « La Société des consultants en administration hospitalière liée » constituée en corporation selon la première partie de la Loi des compagnies en date du 6e jour de mai 1963 et ayant son siège social à Montréal où elle avait son bureau situé à 2648, Avenue de Soissons, l'a transporté à 7705, boul.de l'Aeadie, suite 1206. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme éant son siège social.Donné à Montréal, ce 1er jour de décembre 1971.(Sceau) Le président, Thomas de H.Pocany.43999-0 311-63 La Société des consultants en administration hospitalière ltée Notice is given that \"La Société des consultants en administration hospitalière ltée\" incorporated under Part I of the Companies Act, on the 6th day of May 1963, and having its head office in Montreal, where its office was situated at 2648 De Soissons Avenue has moved it to 7705 de l'Aeadie Boulevard, suite 1206.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 1st day of December 1971 (Sea|) Thomas de H.Pogany, 43999 PreSU!iu.6S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 197S, Vol.104, No.S Les Immeubles Daigle inc.Là compagnie « Les Immeubles Daigle inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Cowansville, au numéro 1369, boulevard Stc-Foy, Longueuil.Le secrétaire, G.Gordon Kohl.43970-o 2557-65 Impression B.T.V.inc.La compagnie « Impression B.T.V.inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Sillery, au numéro' 880, Chemin Ste-Foy, Québec.Le secrétaire, Robert Picard.43971-q 2354-71 Location T.V.Sorel inc.La compagnie « Location T.V.Sorel inc.» donne avis qu'elle a transporté spn siège social de Sorel à 30, place Sicard, Ste-Thérèse de Blainvillc.Le secrétaire, Michael J.Russell.43972 3087-67 Miller Agencies Ltd.La compagnie « Miller Agencies Ltd.» donne avis qu'elle a transporté son siège social de 5761, Honoré de Balzac, Côte Saint-Luc à 6655, chemin Côte des Neiges, Montréal.Le secrétaire, David Miller.43973 715279 Tako Corporation La compagnie « Tako Corporation » constituée en corporation par lettres patentes datées du 27e jour d'avril 1967, et ayant son siège social à Montréal, où jusqu'à ce jour son bureau était situé à 1, place Ville Marie, local 3635, donne avis qu'elle l'a transporté au 2615, avenue Van Horne, en les ville et district de Montréal, province de Québec.À compter de la date de cet avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 8e jour de novembre, 1971.Le secrétaire, Bernice Cohen.43974 1861-67 Les Immeubles Daigle inc.Notice is given that \"Les Immeubles Daigle inc.\" has transferred its head office from Cowansville to number 1369 St.Foy Boulevard, Longueuil.G.Gordon Kohl, Secretary.43970 2557-65 Impression B.T.V.inc.Notice is given that \"Impression B.T.V.inc.\" has transferred its head office from Sillery to number 880 St.Foy Road, Québec.Robert Picard, Secretary.43971 2354-71 Location T.V.Sorel inc.Notice is given that \"Location T.V.Sorel inc.\" has transferred its head office from Sorel to 30 Place Sicard, Ste-Thérèse de Blainville.Michael J.Russell, Secretary.43972-o 3087-67 Miller Agencies Ltd.Notice is given that \"Miller Agencies Ltd.\" has transferred its head office from 5761 Honoré de Balzac, Côte St.Luc to 6655 Côte des Neiges Road, Montreal.43973-0 David Miller, Secretary.715279 Tako Corporation Notice is hereby given that \"Tako Corporation\", incorporated by letters patent on the 27 th day of April, 1967, and having its head office in Montreal, where its office was situated at 1 Place Ville Marie, Suite 3635, has moved it to 2615 Van Horne Avenue, in the city and district of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 8th day of November, 1971.Bernice Cohen, Secretary.43974-0 1861-67 Ministère de l'Éducation Department of Education Lake of Two Mountains (Prot.) Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire protestante de Lake of Two Mountains, dans les comtés de Deux-Montagnes et Laval, les lots 50 à 94 inclusivement et les lots 160 à 235 inclusivement du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Dorothée, Lake of Two Mountains (Prot.) Application is made to detach from the Protestant School Municipality of Lake of Two Mountains, in the counties of Two Mountains and Laval, lots 50 to 94 inclusive and lots 160 to 235 inclusive of the official cadastre of the parish of St.Dorothée, in the county of 218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10U\" année, n° 2 dans le comté de Laval, les lots 236 à 239 inclusivement plus un certain nombre d'îles non cadastrées pour les annexer, pour les protestants seulement, à la municipalité scolaire protestante de Greater St.Martin, dans les comtés de Laval et Fabre.Québec, le 22 décembre 1971.Le minisire de L'Education, Guy Saint-Pierre.43859-1-2-0 960-02 Association coopérative Laval, lots 236 to 239 inclusive, plus a certain number of non-cadastral islands, in order to annex them, for Protestants only, to the Protestant School Municipality of Greater St.Martin, in the counties of Laval and Fabre.Québec, December 22, 1971.Guy Saint-Pierre, Minister of Education.43859-1-2 960-02 Cooperative Association Club coopératif de consommation d'Amos (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « Club coopératif de consommation d'Amos ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Amos, Québec, dans le district électoral d'Abiti-bi-Est.Le sous-ministre des institutionsfina7icières, compagnies et coopératives, 44021-o Ls-Philippe Bouchard.Club coopératif de consommation d'Amos (Cooperative Associatiotis Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the formation of the cooperative association \"Club coopératif de consommation d'Amos\".The head office of this cooperative association is situated in Amos, Québec, in the electoral district of Abitibi East.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, 44021 Companies and Cooperatives.Syndicats professionnels Association des Employés de la Laurentienue (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 3 décembre 1971, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « Association des Employés de la Lau-rentienne », avec siège social situé à Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.44022-o 52-71 Association des Néphrologues du Québec Association of Nephrologists of Québec (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 6 décembre 1971, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « Association des Néphrologues du Québec \u2014 Association of Nephrologists of Québec», avec siège social situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.43983-0 46-71 Professional Syndicates Association des Employés de la Laurentienne (Professional Syndicales Act) Notice is given that on December 3, 1971, the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives authorized the formation of a professional syndicate, under the name of \"Association des Employés de la Laurentienne\", with head office situated in Québec, judicial district of Québec.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44022 52-71 Association des Néphrologues du Québec Association of Nephrologists of Québec (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on December 6, 1971, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Association des Néphrologues du Québec \u2014 Association of Nephrologists of Québec\", with head office situated in Montreal, judicial district of Montreal.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.43983 e 46.7, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 219 Le Syndicat de6 Employés de l'Abattoir Ouellet inc.{Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 29 septembre 1971, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « Le Syndicat des Employés de l'Abattoir Ouellet inc.», avec siège social situé à Ste-Perpétue.district judiciaire de Nicolet.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.44000-o 30-71 Société d'habitation du Québec Municipalité de Moisic Programme de rénovation Avis est donné qu'en vertu de l'article 40 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de 1966-67) le lieutenant-gouverneur en conseil par l'arrêté en conseil numéro 3899 en date du 17 novembre 1971, a décrété « zone de rénovation » le territoire qui fait l'objet du programme de rénovation adopté par la résolution numéro 753 du 22 octobre 1971 de la municipalité de Moisie.Ce programme de rénovation de la municipalité de Moisie a été approuvé par la Société d'habitation du Québec, résolutions numéros 4713-4714 en date du 26 octobre 1971 et cette approbation a été ratifiée par le lieutenant-gouverneur en conseil par ledit arrêté en conseil numéro 3899 du 17 novembre 1971.Le président, 43984-o Jacques Bernier.Office municipal d'habitation de Bedford Municipal Housing Bureau of Bedford Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de 1966-1967), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du vingt-deuxième jour de novembre 1971, constituant en corporation sans but lucratif: Fred Oilman, courtier, 9, rue Rix, Bedford; Lino Marziali, gérant, 66, rue Moreau, Bedford: Jean-Maurice Bédard, vendeur, 160, de l'Église, Bedford; Richard W.Craighead, industriel, Bedford et Laurent Larocque, comptable, 15, Fortin, Bedford; pour les fins suivantes: acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de la ville de Bedford, district judiciaire de liedford.Le président, 43984-0 Jacques Bernier.Le Syndicat des Employés de l'Abattoir Ouellet inc.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies, and Cooperatives gives notice that on September 29, 1971, he authorized the incorporation of a professional syndicate, under the name of \"Le Syndicat des Employés de l'Abattoir Ouellet inc.\", with a head office situated in St.Perpétue, judicial district of Nicolet.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.44000 30-71 Québec Housing Corporation Municipality of Moisie lienewal program Notice is given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1966-67, Chapter 55), the Lieutenant-Governor in Council, by Order number 3899 dated November 17, 1971, declares a \"renewal zone\" the territory covered by the renewal program adopted by resolution number 753 dated October 22, 1971 of the municipality of Moisie.The said renewal program of the municipality of Moisie was approved by the Québec Housing Corporation, resolutions numbers 4713-4714 of .October 26, 1971, and the said approbation was ratified by the Lieutenant-Governor in Council by Order number 3899 of November 17, 1971.Jacques Bernier, 43984-o President.Office municipal d'habitation de Bedford Municipal Housing Bureau of Bedford Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, hearing date of the twenty-second day of November 1971, incorporating as a nonprofit corporation: Fred Oilman, Broker, 9, Rix Street, Bedford; Lino Marziali, Manager, 66, Moreau Street, Bedford; Jean-Maurice Bédard, Salesman, 160, de l'iÉ-glise, Bedford; Richard VV.Craighead, Manufacturer, Bedfonl and Laurent Larocque, accountant.15, Fortin.Bedford; for the following purposes: to acquire, to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Bedford, judicial district of Bedford.Jacques Bernier, 43984-0 President. 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101,' année, n° 2 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies et Institutions, Companies and coopératives Cooperatives Assurance Insurance L'Internationale, compagnie d'assurance-vie The International Life Insurance Company Avis de lettres patentes pourvoyant à la subdivision des actions Avis est donné qu'en vertu de la deuxième partie de la Loi des compagnies, il a été accordé, par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, des lettres patentes, en date du 23e jour de novembre 1971, subdivisant les actions du capital de « L'Internationale, compagnie d'assurance-vie \u2014 The International Life Insurance Company», originairement divisé en 40,000 actions de $25 dollars chacune, ces actions maintenant subdivisées en 200,000 actions de $5 dollars chacune.Daté au bureau du surintendant des assurances, ce 30e jour de décembre 1971.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Le Surintendant des assurances, 43985-0 Roger-A.Camarajre.Liquidation \u2014 Loi de la La Compagnie Locale de Téléphone de Ham-Nord Avis est donné que « La Compagnie Locale de Téléphone de Ham-Nord », constituée en vertu de la Loi des compagnies de télégraphe et de téléphone, chapitre 286, Statuts refondus, 1964, le 15 mai 1911, avec siège social à Ham-Nord, a été dissoute le 21 décembre 1971, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.43975-0 1164-11 Les Entreprises Christian inc.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « Les Entreprises Christian inc.», tenue à Montréal, le 8 octobre 1971, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Marcel Renaud, c.a.a été nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et cooperative.Ls-Philippe Bouchard.43976-0 4216-68 L'Internationale, compagnie d'assurance-vie The International Life Insurance Company Notice of Letters Patent Subdividing the Shares Notice is hereby given that under Part II of the Companies Act, letters patent have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, bearing date the 23rd day of novemher 1971, subdividing the shares of the stock of \"L'Internationale, compagnie d'assurance-vie \u2014 The International Life Insurance Company\", originally divided into 40,000 shares of $25 dollars each, such snares now being subdivided into 200,000 shares of $5 dollars each Dated at the office of the Superintendent of insuran.ces, this 30th day of December 1971.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Roger-A.Camaraire, 43985-0 Superintendent of Insurances.Winding \u2014 Up Act La Compagnie Locale de Téléphone de I lain-.Ni.nl Notice is given that « La Compagnie Locale de Téléphone de Ham-Nord\", incorporated under the Telegraph and Telephone Companies Act, chapter 286, Revised Statutes, 1964, on May 15.1911.with head office in Ham-Nord, has been dissolved on December 21, 1971 pursuant to the Winding-Up Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.43975 ' 1164-11 Les Entreprises Christian inc.Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"Les Entreprises Christian inc.\", held in Montreal on October 8, 1971, it was resolved that the affairs of the said company be liquidated and that it be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act.Mr.Marcel Renaud c.a.was appointed liquidator.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.43976 4216-68 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IS, 1972, Vol.104, No.2 221 Les Placements Guy Fortier inc.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « Les Placements Guy Forlier inc.», tenue à Montréal, le 27 octobre 1971, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Jean-Paul Boyer, c.a., a été nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.43977-0 2516-63 Simga inc.Avis est donné que la compagnie « Simga inc.», constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 23 septembre 1965, avec siège social à Québec, a été dissoute le 11 novembre 1971, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Ls-Philippe Bouchard.43978-0 4261-65 Les Placements Guy Fortier inc.Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"Les Placements Guy Fortier inc.\", held in Montreal on October 27, 1971, it was resolved that the affairs of the said company be liquidated and that it be dissolved, pursuant to the Winding-Up Act.Mr.Jean-Paul Boyer, c.a., was appointed liquidator.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.43977 2516-63 Simga inc.Notice is given that the company \"Simga inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated September 23, 1965, and having its head office in Québec, was dissolved on November 11, 1971, pursuant to the Winding-Up Act.Ls-Philippe Bouchard, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.43978 4261-65 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.Lettres patentes Attendu que chacun des conseils municipaux de la ville de Saint-Eustache et de la paroisse de Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, a adopté, à la majorité absolue de ses membres, un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle1 municipalité sous l'autorité de la Loi de la fusion volontaire'des municipalités; Attendu que les publications requises par l'article 6 de la loi précitée ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec.Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec et que cette dernière n'a pas tenu d'audition publique; Canada Province of HUGUES LAPOINTE Québec (L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Letters Patent Whereas each of the Municipal Councils of the Town of St.Eustache and of the Parish of St.Eustache, County of Two Mountains, has passed, by the absolute majority of its members, a by-law authorizing the presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in Council, praying to be granted letters patent amalgamating these municipalities and creating a new municipality under the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act; Whereas the publication prescribed by section 6 of the aforesaid Act have been made; Whereas copies of the joint petition have been transmitted to the Minister of Municipal Affairs and to the Québec Municipal Commission; Whereas no request for an inquiry has been made to the Québec Municipal Commission and no public hearing has been held by the said Commission ; 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n° 2 Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à la requête conjointe; à ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimes dans un décret portant le numéro 4259, en date du 15 décembre 1971, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons sur la proposition de l'honorable ministre des Affaires municipales, que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la ville de Saint-Eustaehe et la paroisse de Saint-Eustache, comté des Deux-Montagnes, et créant une nouvelle municipalité de ville sous le nom de » Ville de Saint-Eustache », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Ville de Saint-Eustache » ; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère des Terres et Forêts le 6 décembre 1971; cette description apparaît comme annexe « A » du présent arrêté.\u20223.La nouvelle municipalité est régie par la Loi des cités et villes.Les dispositions législatives suivantes s'appliqueront à la nouvelle municipalité.A) Les articles 1,2, 3 du chapitre 82 des lois de 1962; 1$) Les articles 1, 2, 4 ainsi que les alinéas deuxième et troisième de l'article 3 du chapitre 103 des lois de 1965; C) Le chapitre 126 des lois de 1960.4.Le conseil provisoire sera composé des membres du conseil de la ville de Saint-Eustaehe et de la paroisse de Saint-Eustache.Le quorum sera de huit (8) membres.Le maire de la ville de Saint-Eustache en fonction à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes est le maire de la nouvelle municipalité pour la première moitié du terme du conseil provisoire; le maire de la paroisse de Saint-Eustache en fonction à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes est le maire de la nouvelle municipalité pour la deuxième moitié du terme du conseil provisoire.Le maire de la paroisse de Saint-Eustache agira à la fois comme maire suppléant et conseiller pour la première moitié du terme du conseil provisoire et le maire de la ville de Saint-Eustache agira comme maire suppléant et conseiller pour la deuxième moitié du terme du conseil provisoire.Si la charge de maire devient vacante, entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes et celles de la première élection générale, elle est remplie par le maire suppléant jusqu'à la première élection générale.Le conseil provisoire nomme alors un de ses membres comme maire suppléant, jusqu'à la première élection générale.Toute vacance dans le conseil entre la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes et celle de la première élection générale est remplie par le conseil; toutefois, le conseil n'est pas obligé de remplir les vacances tant et aussi longtemps qu'il reste huit (8) membres du conseil en fonction, outre le maire.5.Le règlement no 599 de la ville de Saint-Eustache s'appliquera à la nouvelle municipalité; le maire sup- Whereas it is deemed expedient to grant the said joint petition; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 4259, dated December 15, 1971, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Honourable Minister of Municipal Affairs, that letters patent be issued amalgating the Town of St.Eustache and the Parish of St.Eustache, County of Two Mountains, and creating a new town municipality under the name of \"Town of St.Eustache\", according to the conditions stipulated in the joint petition.These conditions are as follows : 1.The name of the new municipality shall lie \"Town of St.Eustache\"; 2.The territory of the new municipality shall be that officially described by the Department of Lands and Forests on December 6, 1971; this description appears as Appendix \"A\" to the present Order.3.The new municipality shall be governed by the Cities and Towns Act.The following legislative provisions shall apply to the new municipality.(A) Sections 1, 2, 3 of Chapter 82 of the Statutes of 1962; (B) Sections 1, 2, 4 as well as the second and third paragraphs of section 3 of Chapter 103 of the Statutes of 1965; (C) Chapter 126 of the Statutes of 1960.4.The provisional council shall be composed of the members of the Councils of the Town of St.Eustache and the Parish of St.Eustache.Eight members shall constitute a quorum.The incumbent Mayor of the Town of St.Eustache at the time of the coming into force of the letters patent shall be the mayor of the new municipality for the first half of the provisional council's term of office; the incumbent Mayor of the Parish of.St.Eustache at the time of the coming into force of the letters patent shall be the mayor of the new municipality for the second half of the provisional council's term of office.The Mayor of the Parish of St.Eustache shall act both as assistant mayor and adviser for the first half of the provisional council's term of office, and the Mayor of the Town of St.Eustache shall act as assistant mayor and adviser for the second half of the provisional council's term of office.Should the office of mayor become vacant between the date of the coming into force of the letters patent and that of the first general election, it shall be filled by the assistant mayor until the first general election.The provisional council shall then appoint one of its members assistant mayor until the first general election.All vacancies in the council occurring between the date of the coming into force of the letters patent and that of the first general election shall be filled by the council; however, the council shall not be obliged to fill any vacancies as long as eight (8) members of the council, besides the mayor, remain in office.5.By-law No.599 of the Town of St.Eustache shall apply to the new municipality; until the first general QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 223 pléant recevra, jusqu'à la première élection générale, la même indemnité que le maire.6.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu en la salle du conseil de la ville de Saint-Eustache, à 20.00 heures et sans autre convocation.7.La première élection générale du maire et des conseillers aura lieu le premier dimanche de novembre 1972.Les élections générales subséquentes auront lieu tous les quatre (4) ans, le premier dimanche de novembre.8.La liste électorale sera préparée en temps utile pour la première élection générale conformément aux dispositions de la Loi des cités et villes.9.A compter de la première élection générale, le conseil municipal est composé du maire et de huit (8) conseillers élus conformément aux dispositions de la Loi des cités et villes.10.Le territoire de la nouvelle ville de Saint-Eustache n'aura pas de quartiers, mais huit (8) sièges numérotés sans tenir compte du lieu de résidence des candidats.11.Le rôle d'évaluation de la nouvelle ville est composé du rôle d'évaluation de chacune des municipalités lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Le conseil décrétera dans l'année suivante, la confection d'un rôle d'évaluation conformément à la loi; le conseil pourra cependant reviser les rôles d'évaluation en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes jusqu'à l'homologation d'un nouveau rôle d'évaluation.Les dispositions des deux premiers aliénas de l'article 523 de la Loi des cités et villes reprennent tous leurs effets, dès qu'une transaction prévue au quatrième alinéa dudit article est annulée ou résolue en faveur du contractant vendeur ou cédant qui bénéficiait des deux premiers alinéas de l'article 523 de la Loi des cités et villes.12.Les taxes spéciales continueront à être prélevées conformément aux dispositions des règlements d'en-prunt qui en décrètent l'imposition à l'exception de celles imposées par les règlements 497, 510, 531, 532, 533, 543, 527, 512, 536, 550, 409, 430, 434, 435, 475, 441, 515, 522 et 523 de la ville de Saint-Eustache dont le solde des échéances annuelles en capital et intérêts sera à l'avenir imposé et prélevé sur tous les biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité selon leur évaluation.13.Le conseil devra dans un délai de six (6) mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes, adopter un règlement pour fixer un tarif de compensation pour l'usage de l'eau et pour le service d'égouts, et toutes dispositions incompatibles antérieures seront automatiquement abrogées.14.Le coût de l'enlèvement de la neige sera payé à même la taxe foncière générale de la nouvelle municipalité, nonobstant toutes dispositions contraires du règlement 226 de la paroisse de Saint-Eustache, et ce à moins d'une disposition contraire d'un règlement futur de la nouvelle municipalité.15.Le coût de l'éclairage des rues sera payé à même la taxe foncière générale de la nouvelle municipalité, election, the assistant mayor shall receive the same emolument as the mayor.6.The first sitting of the provisional council shall be held on the second judicial Monday following upon the coming into force of the letters patent.It shall take place in the Town Council Hall, in St.Eustache, at 8:00 o'clock p.m., and without further notice.7.The first general election of a mayor and councillors shall be held on the first Sunday of November, 1972.The subsequent general elections shall be held every four (4) years, on the first Sunday of November.8.The electoral list shall be prepared in due time for the first general election, in conformity with the provisions of the Cities and Towns Act.9.With effect from the first general election, the Municipal Council shall be composed of a mayor and eight (8) councillors elected in conformity with the provisions of the Cities and Towns Act.10.The territory of the new Town of St.Eustache shall not be divided into wards; the eight (8) council seats shall each be designated by a number without any bearing on the candidate's place of residence.11.The valuation roll of the new town shall be composed of the valuation rolls of the two municipalities in effect upon the coming into force of the letters patent.During the following year, the Council shall order the preparation of a valuation roll in conformity with the law; the Council may, however, revise the valuation rolls in effect upon the coming into force of the letters patent until the ratification of a new valuation roll.The provisions of the first two paragraphs of section 523 of the Cities and Towns Act shall again have effect as soon as any transaction provided for in the fourth paragraph of the said section is cancelled or terminated in favour of the contracting vendor or assignor who benefitted from the first two paragraphs of section 523 of the Cities and Towns Act.12.The special taxes shall continue to be levied in conformity with the provisions of the loan by-laws decreeing their imposition, with the exception of those imposed by bv-laws 497, 510, 531, 532, 533, 543, 527, 512, 536, 550.409, 430, 434, 435, 475, 441, 515, 522 and 523 of the Town of St.Eustache, whose balance of annual maturities in capital and interest shall, in the future, be imposed and levied on all the taxable immovable property in the new municipality, according to their evaluation.13.The council, with the six (6) months following upon the coming into force of these letters patent, shall pass a by-law fixing a compensation tariff for water and sewer services and all former incompatible provisions shall be automatically repealed.14.The cost of snow removal shall be paid from the general land tax of the new municipality, notwithstanding any contrary provisions of by-law 226 of the parish of St.Eustache.The foregoing shall apply unless the municipality pass, in the future, a by-law containing a provision to the contrary.15.The cost of street-lighting shall be paid from the general land tax of the new municipality, notwithstand- 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1971, 10V année, n' St nonobstant toutes dispositions contraires du règlement 310 de la paroisse de Saint-Eustache.16.Les rues de la paroisse de Saint-Eustache, ayant une fondation primaire à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes, recevront une fondation secondaire et du pavage, dans au plus une (1) année de la date de la décision du conseil de la nouvelle municipalité à cet effet; ces travaux seront payés à même une taxe foncière répartie sur tous les biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité, selon leur évaluation.17.Les fonctionnaires et employés permanents des deux municipalités fusionnées demeurent au service de la nouvelle ville dans les fonctions qui leur seront attribuées par le nouveau conseil, sans diminution de traitement ou de salaire.18.Le fonds industriel de la ville de Saint-Eustache constituera le fonds industriel de la nouvelle ville.19.La nouvelle municipalité pourra adopter un règlement d'emprunt pour consolider le déficit accumulé de l'ancienne ville de Saint-Eustache au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes; ce règlement imposera une taxe foncière spéciale sur tous les biens-fonds imposables de l'ancienne ville de Saint-Eustache selon leur évaluation.Ce règlement d'emprunt ne requerra pas d'autres approbations que celles de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales.20.La nouvelle municipalité pourra adopter un règlement d'emprunt pour consolider l'emprunt temporaire au 31 décembre 1971, de l'ancienne ville de Saint-Eustache à la Banque Provinciale de Saint-Eustache concernant le fonds industriel de l'ancienne ville de Saint-Eustache; ce règlement imposera une taxe foncière spéciale sur tous les biens-fonds imposables de la nouvelle ville selon leur évaluation.Ce règlement d'emprunt ne requerra pas d'autres approbations que celles de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales.21.L'utilisation du surplus du fonds industriel prévu à l'article 5 de la Loi des fonds industriels devra être affecté en priorité au remboursement des échéances annuelles en capital et intérêts de l'emprunt décrété à l'article 20 de la présente requête conjointe.22.La Cour municipale de la ville de Saint-Eustache constituera la Cour municipale de la nouvelle ville de Saint-Eustache.23.La nouvelle ville deviendra effective suivant la loi.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., or., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quinzième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingtième année.Par ordre, Libro: 1536 Jean Alarie, Folio: 13 Sous-procureur général adjoint.ing any contrary provisions of by-law 310 of the Parish of Eustache.16.A base course and pavement surface shall be laid on the streets of the Parish of St.Eustache which have been given a sub-base course prior to the coming into force of the letters patent, within one (1) year from the date of the decision of the new municipal council to this effect.These works shall be paid from a land tax assessed on all the taxable immovable property in the new municipality, according to its evaluation.17.The officers and permanent employees of the two amalgamating municipalities shall remain in the employ of the new municipality in the duties assigned to them by the new council, without decrease of pay or salary.18.The industrial capital of the Ton u of St.Eustache shall constitute the industrial capital of the new town.19.The new municipality may pass a loan by-law to consolidate the accumulated deficit of the former Town of St.Eustache at the time of the coming into force of the letters patent; this by-law shall provide for the imposition of a special land tax on all the taxable immovable property in the former Town of St.Eustache, based on its evaluation.This loan by-law shall require no other authorization than that of the Québec Municipal Commission and of the Minister of Municipal Affairs.20.The hew municipality may pass a loan by-law to consolidate the temporary loan contracted on December 31, 1971 by the former Town of St.Eustache from the Provincial Bank of St.Eustache.concerning the industrial capital of the former Town of St.Eustache; this by-law shall provide for the imposition of a special land tax on all the taxable immovable property in the new town, based on its evaluation.This loan by-law shall require no other authorization than that of the Québec Municipal Commission and of the Minister of Municipal Affairs.21.All surplus in the industrial capital provided for in section 5 of the Industrial Capital Act shall be utilized primarily for the reimbursement of annual maturities, in capital and interest, of the loan decreed in section 20 of the present joint petition.22.The Municipal Court of the town of St.Eustache shall constitute the Municipal Court of the new Town of St.Eustache.23.The new town shall take effect according to law.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to he made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifteenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-one and in the twentieth year of Our Reign.By command, Libro: 1536 Jean Alarie, roho: 13 Assistant Deputy Attorney General. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 197S, Vol.104, No.S 225 Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi de la fusion volontaire des municipalités.Le sous-ministre des Affaires municipales, 44007-o Richard Beauueu.Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.(L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux qui ces présentes lettres verront ou qu'icelles pourront concerner.Salut.Lettres patentes Attendu que l'article 2 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur requête du conseil d'une corporation municipale régie par cette loi, peut émettre des lettres patentes modifiant la charte de cette corporation, en y remplaçant certaines dispositions par celles de la Loi des cités et villes qui y correspondent-, Attendu que le conseil de la ville de Maple Grove, par sa requête en date du 5 octobre 1971, demande que des lettres patentes soient émises en sa faveur à l'effet de modifier sa charte en y remplaçant toutes les dispositions du chapitre 94 des lois de 1918, à l'exception des articles 1, 2, 3, 8 et 26 de la loi susdite, par les dispositions correspondantes de la Loi des cités et villes; Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies; Attendu Qu'il est opportun de se rendre à cette demande.A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil Exécutif, exprimés dans un décret portant le numéro 4255, en date du 15 décembre 1971, Nous accordons la requête du conseil de la ville de Maple Grove, en date du 5 octobre 1971, et Nous déclarons et ordonnons, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, que les dispositions du chapitre 94 des lois de 1918.à l'exception des articles 1, 2, 3, 8 et 26 de la loi susdite, soient remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi des cités et villes, le tout conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193).En foi de qoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, op., or., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Notice of the abovementioned letters patent is given pursuant to the provisions of section 13 of the Voluntary Amalgamation of Municipalities Act.Richard Beaulieu, 44007 Deputy Minister of Municipal Affairs.Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Letters Patent Whereas section 2 of the Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 193), provides that the Lieutenant-Governor in Council upon the petition of the council of a municipal corporation governed by this Act, may issue letters patent amending the charter of such corporation by replacing certain of the charter provisions by those of the Cities and Towns Act corresponding thereto; Whereas the Council of the Town of Maple Grove, by its petition dated October 5, 1971, prays that letters patent be issued to amend its charter by replacing all the provisions of chapter 94 of the Statutes of 1918, with the exception of sections 1, 2, 3, 8 and 26 of the aforesaid Act, by the corresponding provisions of the Cities and Towns Act; Whereas all the formalities prescribed by law have been complied with; Whereas it is expedient to grant this petition; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 4255, dated December 15, 1971, We hereby grant the petition of the Council of the Town of Maple Grove, , dated October 5, 1971.and do hereby decree and order, by these letters patent which shall come into force upon, from and after their publication in the Québec Official Gazelle, that the provisions of chapter 94 of the Statutes of 1918, with the exception of sections 1, 2, 3, 8 and 26 of the aforesaid Act, be replaced by the corresponding provisions of the Cities and Towns Act, the whole in conformity with the provisions of section 2 of the said Cities and Towns Act (Revised Statutes, 1964, chapter 193).In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.o, q.o, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec. 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 104' année, nc S Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce quinzième jour de décembre en l'année mil neuf cent soixante et onze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingtième année.Par ordre, Libro: 1536 Jean Alarie, Folio: 12 Sous-procureur général adjoint.Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193).Le sous-ministre des Affaires municipales, 44007-o Richard Beaulieu.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this fifteenth day of December in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-one and in the twentieth year of Our Reign.By command, Libro: 1536 Jean Alarie, Folio: 12 Assistant Deputy Attorney General.Notice of the granting of the above letters patent is given pursuant to the provisions of section 15 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1964, chapter 193).Richard Beaulieu, 44007 Deputy Minister of Municipal Affairs.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications James Arthur Ryan Avis est par les présentes donné, selon l'article 5, Loi du changement de nom, que James Arthur Ryan, préposé aux wagons, de 7550 Chambord #13, des cité et district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant son nom à James Arthur Miller.Le changement de nom bénéficiera aussi à sa femme, de la même adresse.Montréal, le 29 décembre 1971.Le.' procureurs du requérant, 43915-2-2-o Mes Hamel & Bélanger.Tohmc Yousscf Tohme Avis est donné par la présente que Tohme Youssef Tohme, fleuriste, domicilié à 66 rue Main, Gatineau, dans le district de Hull, province de Québec, adressera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer son nom en celui de Tom Thomas.Gatineau, ce 17e jour de décembre 1971.Les procureurs du requérant, 43993-2-2-0 Dagenais & Dagenais.James Arthur Ryan Notice is hereby given pursuant to section 5 of the Change of Name Act that James Arthur Ryan, car-man, residing at 7550 Chambord #13, in the city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in council of the Province of Québec for the adoption of an order changing his name to James Arthur Miller.The change of name shall benefit his wife of the same address.Montreal, December 29, 1971.Messrs.Hamel & Bélanger, 43915-2-2-0 Attorneys for the A pplicanl.Tohme Youssef Tohmc Notice is given by the present that Tohme Youssef Tohme, restorator and Florist, domiciled at Gatineau, district of Hull, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change is name for Tom Thomas.Gatineau, this 17th day of December 1971.Dagenais & Dagenais, 43993-2-2-0 Attorneys for Petitioner.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Les Commissaires d'écoles catholiques pour la municipalité de Châteaugua) Comté de Châteauguay Avis de correction Veuillez prendre note que dans l'avis de demande de soumissions pour l'achat de $280.000 d'obligations pour les commissaires d'écoles catholiques' pour la municipalité de Châteauguay, comté de Châteauguay, qui a paru dans la Gazette officielle du 24 décembre 1971, à la page 9403, dans le tableau d'amortissement dans The Municipality of Châteauguay Catholic School Commissioners County of Châteauguay Notice of correction Kindly note that in the notice of call for tenders for the purchase of $280,000 of bonds of the municipality of Châteauguay School Commissioners, county of Châteauguay, published in the Québec Official Gazette of December 24, 1971, on page 9403, in the table of redemption shown in the notice, the dates of redemption QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.m.No.2 227 ledit avis, les dates d'échéance du capital devaient se lire « du 1er février 1973 au 1er février 1982 » au lieu de « du 1er janvier 1973 au 1er janvier 1982 ».Tous les autres détails contenus dans l'avis de demande de soumissions indiqué ci-haut demeurent inchangés.Châteauguay, ce 10 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Maurice Casavant.Bureau administratif, 184, boul.Salaberry Nord, Châteauguay, (Comté de Châteauguay), P.Q.44007-O Cité de Pointe-aux-Tremblcs Comté de Lafontaine Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Guy Vanier, greffier, Hôtel de ville, 11953, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, comté de Lafontaine, P.Q., jusqu'à 5.30 heures de l'après-midi, lundi, le 31 janvier 1972, pour l'achat de 81,600,000 d'obligations de la cité de Pointe-aux-Trembles, comté de Lafontaine, datées du 15 février 1972, divisées en deux séries comme suit: Série « A » : au montant de 81,000,000 remboursable en série du 15 février 1973 au 15 février 1978 inclusivement.Tableau d'amortissement \u2014 SI.000,000 \u2014 6 ans Année Capital 15 février 1973.$140,000 15 février 1974.150,000 15 février 1975.160,000 15 février 1976.170,000 15 février 1977.180,000 15 février 1978 .200,000 On est prié de noter que pour cette série « A » seulement, des soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.Les obligations de ladite série « A » seront racheta-bles par anticipation en tout ou en partie, au pair, à toute date d'échéance d'intérêt.Les obligations de la \u2022 présente série « A » seront émises en vertu du règlement numéro 497 \u2014 $1,000,000 \u2014 achat de terrains pour fins industrielles.Série « B » : au montant de $600,000 remboursable en série du 15 février 1973 au 15 février 1992 inclusivement.Tableau d'amortissement \u2014 $600,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 février 1973.$ 5,000 15 février 1974 .5.000 15 février 1975 .6,000 15 février 1976.6,000 15 lévrier 1977 .7,000 15 février 1978.7,000 maturities issue shall be read \"February 1st, 1973 to February 1st, 1982\" instead of \"January 1st, 1973 to January 1st, 1982\".All the other details contained in the above mentioned notice of call for tenders remain unchanged.Châteauguay, January 10, 1972.Maurice Casavant, Secretary-Treasurer.Administration Office, 184 Salaberry Boulevard North, Châteauguay, (County of Châteauguav), P.Q.44007 City of Pointe-aux-Trembles County of Lafontaine Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will lie received by the undersigned, Guy Vanier, City Clerk, at the City Hall, 11953 Notre-Dame Street East, Pointe-aux-Trembles, Coimty of Lafontaine, P.Q., until 5:30 o'clock, p.m., on Monday, January 31, 1972, for the purchase of a bond issue of $1,600,000 for the City of Pointe-aux-Trembles, County of Lafontaine, dated February 15, 1972, divided into two series as follows: Series \"A\": in the amount of $1,000,000 redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1978 inclusive.Redemption table \u2014 SI ,000,000 \u2014 6 years Year Capital February 15, 1973.$140,000 February 15, 1974.150,000 February 15, 1975.160,000 February 15, 1976.170,000 February 15, 1977.180,000 February 15, 1978 .200,000 Please note that tenders are called for Series \"A\" bonds redeemable according to the above table only, and that offers for short-term bonds will not be considered.The bonds of the said Series \"A\" are redeemable by anticipation, in whole or in part, at par, on any interest maturity date.The bonds of this Series \"A\" will be issued pursuant to by-law number 497 \u2014 $1,000,000 \u2014 purchase of lands for industrial purposes.Series \"B\": in the amount of $600,000 redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1992 inclusive.Redemption table \u2014 $600,000 \u2014 20 years Year Capital February 15, 1973.$ 5,000 February 15, 1974 .5,000 February 15, 1975.6,000 February 15, 1976 .6,000 February 15, 1977.7,000 February 15, 1978 .7,000 228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10V année, n° 2 15 février 1979.S 8,000 15 février 1980.9,000 15 février 1981.9,000 15 février 1982.10,000 15 février 1983.11,000 15 février 1984.12,000 15 février 1985.13,000 15 février 1986.14,000 15 février 1987.15,000 15 février 1988.17,000 15 février 1989.18,000 15 février 1990.19,000 15 février 1991.21,000 15 février 1992 .388,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1\" Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $51,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis pour ladite série « B » et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 2002.L'échéance du 15 février 1992 au montant de $388,000 comprend un solde de $365,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: February 15, 1979.S 8,000 February 15, 1980 .9,000 February 15, 1981.9,000 February 15, 1982.10,000 February 15, 1983.11,000 February 15, 1984.12,000 February 15, 1985.13,000 February 15, 1986.14,000 February 15, 1987.15,000 February 15, 1988.17,000 February 15, 1989.18,000 February 15, 1990.19,000 February 15, 1991.21,000 February 15,.1992 .388,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years lor the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $51,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice for the said Series \"B\" and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15, 2002.The maturity of February 15, 1992 in the amount of 8388,000 includes a balance of $365,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Année Capital 15 février 1993.$25,000 15 février 1994.27,000 15 février 1995.29,000 15 février 1996.32,000 15 lévrier 1997.34,000 15 février 1998.37,000 15 février 1999.40,000 15 février 2000 .43,000 15 février 2001.47,000 15 février 2002 .51,000 Les obligations de ladite série « B > ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $388,000; les obligations ainsi émises seront rachetables par anticipation, au pair, le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances de la série « B » apparaissant ci-haut.Les obligations de la présente série « B » seront émises en vertu du règlement numéro 505 \u2014 S600.000 \u2014 aqueduc et égouts.Year Capital February 15, 1993.$25,000 February 15, 1994.27,000 February 15, 1995.29,000 February 15, 1996 .32,000 February 15, 1997 .34,000 February 15, 1998 .37,000 February 15, 1999.40,000 February 15, 2000.43,000 February 15, 2001.47,000 February 15, 2002 .51,000 The bonds for the said Series \"B\" will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $388,000; the bonds thus issued will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table of Series \"B\" shown above.The bonds of the said Scries \"B\" will be issued pursuant to by-law number 505 \u2014 $600,000 \u2014 aqueduct and sewers. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, A'o.2 229 Le taux d'intérêt ne devra pas être inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, et ces intérêts seront payables semi-annuellement les 15 février et 15 août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission ou il peut varier suivant les séries ou les échéances; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tels que montrés aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1972.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émissions énumé-rées pour chacune des séries ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans le cas des exceptions notées.De plus, seul les soumissions pour la totalité des obligations des deux séries seront considérées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, au prix indiqué dans sa soumission en capital plus les intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Pointe-aux-Trembles.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Pointe-aux-Trembles s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue lundi, le 31 janvier 1972, à 5.30 heures de l'après-midi, Hôtel de ville, 11953, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, comté de Lafontaine, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pointe-aux-Trembles (Comté de Lafontaine), ce 10 janvier 1972.Le greffier, Guy Vantée.Hôtel de Ville, 11953, rue Notre-Dame Est, Pointe-aux-Trembles, (Lafontaine), P.Q.Téléphone: 645-5381, code 514.44019-O Paroisse de Bagotville Comté de Chicoutimi Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Rosaire Poitras, secrétaire-trésorier.Salle municipale, 288, rue Albert, Bagotville, comté de Chicoutimi, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 2 The rate of interest shall not be less than 7%, nor more than 8%, and shall be payable half-yearly on February 15th and August 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue or it may vary according to the Scries or maturities; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption tables in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1972.However, tenders should be sent for one only of the methods of issue listed for each of the abovementioned Series, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.It should further be noted that only those tenders submitted for the total of each of the maturities mentioned in each series will be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Pointe-aux-Trembles.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Pointe-aux-Trembles agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after February 15, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees, as the case mav be, to be held on Monday, January 31, 1972, at 5:30 o'clock, p.m.at the City Hall, 11953 Notre-Dame Street East, Pointe-aux-Trembles, County of Lafontaine, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of .the tenders.Pointe-aux-Trembles (County of Lafontaine), January 10, 1972.Guy Vanier, Cily Clerk.City Hall, 11953 Notre-Dame Street East, Pointe-aux-Trembles, (Lafontaine), P.Q.Telephone: 645-5381, code 514.44019 Parish of Bagotville County of Chicoutimi Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Rosaire Poitras, Secretary-Treasurer, at the Municipal Hall, 288 Albert Street, Bagotville, County of Chicoutimi, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, February 2nd 1972, for the purchase of 230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 104' année, n° 2 février 1972, pour l'achat de 8101,000 d'obligations de la paroisse de Bagotville, comté de Chicoutimi, datées du 15 février 1972 et remboursables en série du 15 février 1973 au 15 février 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 15 février et 15 août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour 6ns d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $101,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 février 1973.81,500 15 février 1974.1,500 15 février 1975.1,500 15 février 1976.1.500 15 février 1977.1,500 15 février 1978 .2,000 15 février 1979 .2,000 15 février 1980 .2,000 15 février 1981.2,000 15 février 1982 .2,000 15 février 1983 .3,500 15 février 1984 .3,500 15 février 1985.3,500 15 février 1986 .3,500 15 février 1987.3,500 15 février 1988 .4,500 15 février 1989 .4,500 15 février 1990 .4,500 15 février 1991.5,000 15 février 1992.47,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $5,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 2002 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera f aite conformément à la loi.a bond issue of $101,000 for the Parish of Bagotville, County of Chicoutimi, dated February 15, 1972, and redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than .8%, payable half-yearly on February 15th and August 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1972.Redemption table \u2014 $101,000 \u2014 20 years Year Capital February 15, 1973.$1,500 February 15, 1974.1,500 February 15, 1975.1,500 February 15, 1976.1,500 February 15, 1977.1,500 February 15, 1978 .2,000 February 15, 1979 .2,000 February 15, 1980 .2,000 February 15, 1981.2,000 February 15, 1982.2,000 February 15, 1983.3,500 February 15, 1984 .3,500 February 15, 1985.3,500 February 15, 1986.3,500 February 15,1987.3,500 February 15, 1988 .4,500 February 15, 1989.4,500 February 15, 1990.4,500 February 15, 1991.5,000 February 15, 1992.47,500 Moreover, the following terms and conditions only shall be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $5,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15, 2002 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication shall be made according to law. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1973, Vol.104, No.S 231 L'échéance du 15 février 1992 au montant de $47,500 comprend un solde de $42,500 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Année Capital 15 février 1993.$3,500 15 février 1994 .3,500 15 février 1995 .3,500 15 février 1996 .3,500 15 février 1997.3,500 15 février 1998.5,000 15 février 1999 .5,000 15 février 2000.5,000 15 février 2001.5,000 15 février 2002.5,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Bagotville.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $47,500 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de Bagotville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 116 tel que modifié ¦\u2014 $18,000 \u2014 aqueduc, égouts; 118 \u2014 $74,000 \u2014 aqueduc, égouts; 119 \u2014 $9,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, mercredi, le 2 février 1972, à 8 heures du soir, Salle municipale, 288, rue Albert, Bagotville, comté de Chicoutimi, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Bagotville (Comté de Chicoutimi), ce 4 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier.Rosaire Poitras.Salle municipale, 288, rue Albert, Bagotville (Comté de Chicoutimi), P.Q.Téléphone: 544-2713, code 418.43980-o Ville de Sainte-Agathc-des-Monts Comté de Terrebonne Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription * Sou- The maturity of February 15, 1992 in the amount of $47,500 includes a balance of $42,500 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Year Capital February 15, 1993.$3,500 February 15, 1994.3,500 February 15, 1995 .3,500 February 15, 1996 .3,500 February 15, 1997.3,500 February 15, 1998.5,000 February 15, 1999.5,000 February 15, 2000 .5,000 February 15, 2001.5,000 February 15, 2002.5,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, capital and accrued interest, if any, by certified cheque payable at par at Bagotville.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procédure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $47,500 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of Bagotville agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after February 15, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 116 as amended \u2014 $18,000 aqueduct, sewers; 118 \u2014 $74,000 \u2014 aqueduct, sewers; 119 \u2014 $9,000 \u2014 aqueduct, sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Wednesday, February 2nd 1972, at 8:00 o'clock p.m., in the Municipal Hall, 288 Albert Street, Bagotville, County of Chicoutimi, P.Q.The council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Bagotville (County of Chicoutimi), January 4, 1972.Rosaire Poitras, Secreta ry-Treasu rer.Municipal Hall, 288 Albert Street, Bagotville (County of Chicoutimi), P.Q.Telephone : 544-2713, code 418.43980 Town of St.Agathc-des-Monts County of Terrebonne Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the 232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 197S, 10k' année, n° S missions pour obligations » seront reçues par le soussigné Marcel Hardy, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 50, rue Saint-Joseph, case postale 40, Sainte-Agathe-dcs-Monts, comté de Terrebonne, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 1er février 1972, pour l'achat de $638,000 d'obligations de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne, datées du 15 février 1972 et remboursables en série du 15 février 1973 au 15 février 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 15 février et 15 août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émist-sion; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1972.undersigned, Marcel Hardy, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 50 St.Joseph Street, Post Office Box 40, St.Agathe-des-Monts, County of Terrebonne, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, February 1, 1972, for the purchase of a bond issue of $638,000 for the Town of St.Agathe-des-Monts, County of Terrebonne, dated February 15, 1972 and redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on February 15th and August 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1972.Tableau d'amortissement \u2014 S638,000 \u2014 SO ans Année Capital 15 février 1973.$15,000 15 février 1974.17,000 15 février 1975.19,000 15 février 1976 .20,000 15 février 1977 .22,000 15 février 1978 .24.000 15 février 1979 .26,000 15 février 1980 .27.000 15 février 1981.29.000 15 février 1982 .31,000 15 février 1983 .33,000 15 février 1984 .36.000 15 février 1985.39.000 15 février 1986.41,000 15 février 1987 .45,000 15 février 1988 .37,000 15 février 1989 .40,000 15 février 1990 .42,000 15 février 1991.46,000 15 février 1992.49.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $49,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenaitI compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 1992.Redemption table \u2014 $638,000 \u2014 SO years Year Capital February 15, 1973.$15,000 February 15, 1974.17.000 February 15, 1975.19,000 February 15, 1976 .20,000 February 15, 1977 .22,000 February 15, 1978 .24,000 February 15, 1979 .26,000 February 15, 1980 .27,000 February 15, 1981.29,000 F'ebruary 15, 1982.31,000 February 15, 1983 .33,000 February 15, 1984 .36,000 February 15, 1985 .39.000 February 15, 1986.41,000 February 15, 1987 .45,000 February 15, 1988 .37,000 February 15, 1989 .40,000 February 15, 1990 .42,000 February 15, 1991.46.000 February 15, 1992.49,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial Ixinds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-ycar fixed-term bonds should not be for an amount less than $49,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starling with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15, 1992. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 233 Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Sainte-Agathe.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 849,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Sainte-Agathe-des-Monts s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 436 \u2014 8100,000 \u2014 fonds de roulement; 439 \u2014 827,500 \u2014 construction d'une usine d'épuration; 444 \u2014 895,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 461 \u2014 $255,000 \u2014 consolidation de déficit; 462 \u2014 8160,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, mardi, le 1er février 1972, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 50, rue Saint-Joseph, case postale 40, Sainte-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ste-Agathe-des-Monts (Comté de Terrebonne), ce 10 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Marcel Hardt.Hôtel de ville, 50, rue St-Joseph, case postale 40, Ste-Agathe-des-Monts (Comté de Terrebonne), P.Q.Téléphone : 326-4595, code 819.44018-o Les Commissaires d'écoles pour la municipalité de la paroisse de l'Ancienne-Lorette Comté de Chauveau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Claude Drolet, secrétaire-trésorier.Ecole Falar-deau, 1400, rue Falardeau (Ancienne-Lorette), Saintc-Foy, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 1er février 1972, pour l'achat de S717,500 d'obligations des coni- However, tenders should be sent for one only of the above methods of issue, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at St.Agathe.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $49,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Agathe-des-Monts agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after February 15, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following by-laws: 436 \u2014 8100,000 \u2014 working capital; 439 \u2014 $27,500 \u2014 construction of a filtering plant; 444 \u2014 $95,500 \u2014 aqueduct, sewers, roads; 461 \u2014 $255,000 funding of deficit; 462 \u2014 $160,000 \u2014 aqueduct, sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Tuesday, February 1, 1972.at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 50 St.Josepht stree.Post Office Box 40, St.Agathe-des-Monts, County of Terrebonne, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Agathe-des-Monts (County of Terrebonne), January 10, 1972.Marcel Hardy, Secretary-Treasurer.Town Hall, 50 St.Joseph Street, Post Office Box 40, St.Agathe-des-Monts (County of Terrebonne), P.Q.Telephone: 326-4595, code 819.44018 The School Commissioners of the Parish of Aneienne-Lorette County of Chauveau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Claude Drolet, Secretary-Treasurer, Falardeau School, 1400 Falardeau Street (Aneienne-Lorette), St.Foy, P.Q.until 8:00 o'clock, p.m., on Tuesday, February 1, 1972, for the purchase of a bond issue of $717,500 for the School Commissioners of the 234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 101,' année, n° 2 missaires d'écoles pour la municipalité de la paroisse de L'Ancienne-Lorette, comté de Chauveau, datées du 1er février 1972 et remboursables en série du 1er février 1973 au 1er février 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annucllement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1972.Municipality of the Parish of Aneienne-Lorette, County of Chauveau, dated February 1, 1972 and redeemable serially from February 1, 1973 to February 1, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 1, 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $717,500 \u2014 20 ans Année Capital 1er février 1973.x $58,500 1er février 1974.x 64,000 1er février 1975.x 69,000 1er février 1976.x 74,000 1er février 1977.x 79,500 1er février 1978.x 86,500 1er février 1979.15,000 1er février 1980.16,000 1er février 1981.17,500 1er février 1982.18,500 1er février 1983.15,000 1er février 1984.16,000 1er février 1985.18,000 1er février 1986.19,000 1er février 1987 .21.000 1er février 1988 .22,000 1er février 1989 .24,000 1er février 1990.26.000 1er février 1991.28,000 1er février 1992 .30,000 Les « x » indiquent les années durant lesquelles les versements annuels d'une subvention de $468,000, accordée par le gouvernement provincial et payable en 6 versements de $78,000 de 1973 à 1978 inclusivement, seront appliqués au service de cet emprunt.Les versements effectués à même cette subvention seront déposés durant les années précitées entre les mains du ministre des Finances en vue de compléter les sommes nécessaires pour acquitter en totalité le service de la dette sur cette émission conformément aux dispositions du Bill 64.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la paroisse de l'Ancienne-Lorettc, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demanderont au ministre de l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire (y compris celles indiquées ci-haut), le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.Redemption table \u2014 $717,600 \u2014 20 years Year Capital February 1, 1973.x $58,500 February 1, 1974.x 64,000 February 1, 1975.x 69,000 February 1, 1976.x 74,000 February 1, 1977.x 79,500 February 1, 1978.x 86,500 February 1, 1979.15,000 February 1, 1980.16,000 February 1, 1981.17,500 February 1, 1982.18,500 February 1, 1983.15,000 February 1, 1984.16,000 February 1, 1985.18,000 February 1, 1986.19,000 February 1, 1987 .21,000 February 1, 1988.22,000 February 1, 1989 .24,000 February 1, 1990.26.000 February 1, 1991.2S.000 February 1, 1992 .30,000 The years marked with the letter \"x\" indicate those years during which the annual instalments of a grant of $468,000, awarded by the Provincial Government and payable in 6 instalments of $78,000 from 1973 to 1978 inclusive, will be applied to the service of this loan.The instalments paid on this grant will be deposited during the aforesaid years with the Minister of Finance for the purpose of completing the sums required to pay off the aggregate amount of the service of the debt on this issue, in conformity with the provisions of Bill 64.The School Commissioners of the Municipality of the Parish of Ancienne Lorette, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.104, No.2 235 2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $30,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er février 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus, s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à l'Ancienne-Lorette.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $30.000.et seul cet excédent sera raehetable par anticipation, au pair, le 1er février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la paroisse de l'Ancienne-Lorette s'engagent à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 10 décembre 1956 \u2014 $35,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; et de la résolution datées du 24 août 1971 \u2014 $682,000 \u2014 agrandissement de l'école Falardeau et dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, mardi, le 1er février 1972, Ecole Falardeau, 1400, rue Falardeau, (Ancienne-Lorette), Sainte-Foy, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Foy, ce 5 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Claude Dbolet.École Falardeau, 1400, rue Falardeau, (Ancienne-Lorette), Sainte-Foy, P.Q.Téléphone: 872-1102, code 418.43981-0 2.1 to 15-year serial bonds with the balance'carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-tenn bonds.4.1 to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-ycar fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $30,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 1, 1992.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Ancienne-Lorette.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $30,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The School Commissioners of the Municipality of the Parish of Ancienne-Lorette agree not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after February 1, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated December 10, 1956 \u2014 $35,500 \u2014_loan renewal; and the resolution dated August 24, 1971 \u2014 $682,000 \u2014 enlargement of the Falardeau School and real property expenses.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held at 8:00 o'clock, p.m., on Tuesday, February 1, 1972, at Falardeau School, 1400 Falardeau Street, (Ancienne-Lorette), St.Foy, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St.Foy, January 5, 1972.Claude Drolet, Secreta ry-Treasurer.Falardeau School, 1400 Falardeau Street, (Ancienne-Lorette), St.Foy, P.Q.Telephone : 87 2-1102, code 418.43981 236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10i' année, n\" * Paroisse de St-Roch-de-l'Achigan Comté de L'Assomption Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean-Denis Beauchamps, secrétaire-trésorier, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Bureau du secrétaire-trésorier, 480, rue Principale, case postale 150, Saint-Roch-de-l'Achigan, comté de L'Assomption, P.Q,, et par après jusqu'à 8 heures du soir.Sous-sol de l'Église, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, comté de L'Assomption, P.Q., lundi, le 31 janvier 1972.pour l'achat de 8500.000 d'obligations de la paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan, comté de L'Assomption, datées du 15 février 1972 et remboursables en série du 15 février 1973 au 15 février 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à S%, payable scuii-annuellcment les 15 février et 15 août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $600,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 février 1973.$ 1,000 15 février 1974 .2,000 15 février 1975 .2,000 15 février 1976.2,000 15 février 1977 .2,000 15 février 1978.3,000 15 février 1979 .3,000 15 février 1980.3,000 15 février 1981.3,000 15 février 1982 .3,000 15 février 1983.4,000 15 février 1984.4,000 15 février 1985 .4,000 15 février 1986 .5,000 15 février 1987.6,000 15 février 1988.6,000 15 février 1989 .6,000 15 février 1990 .7,000 15 février 1991.7,000 15 février 1992 .427,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le >olde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être Parish of St.Roch-de-PAchigan County of L'Assomption Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned Jean-Denis Beauchamps, Secretary-Treasurer, until 5:00 o'clock p.m., at the Office of the Secretary-Treasurer, 480 Principale Street, Post Office Box 150, St.Roeh-de-PAchigan, County of L'Assomption, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., in the Church Basement, Principale Street, St.Roch-de-I'Achigan, County of L'Assomption, P.Q., on Monday, January 31, 1972, for the purchase of a bond issue of $500,000 for the Parish of St.Roch-de-l'Achigan, County of L'Assomption, dated February 15, 1972 and redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on February 15th and August 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, if more than one rate is used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1972.Redemption table \u2014 $500,000 \u2014 20 years Year Capital February 15, 1973.$ 1,000 February 15, 1974 .2,000 February 15, 1975.2,000 February 15, 1976 .2,000 February 15, 1977 .2,000 February 15, 1978.3,000 February 15, 1979.3,000 February 15, 1980 .3,000 February 15, 1981.3,000 February 15, 1982.3,000 February 15, 1983 .4,000 February 15, 1984 .4,000 February 15, 1985 .4,000 February 15, 1986.5,000 February 15, 1987.0,000 February 15, 1988.6,000 February 15, 1989 .6,000 February 15, 1990 .7,000 F'ebruary 15, 1991.7,000 February 15, 1992.427,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 237 pour un montant inférieur à $40,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 2012 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la ioi.L'échéance du 15 février 1992 au montant de $427,000 comprend un solde de $419,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Année Capital 15 février 1993.$ 9,000 15 février 1994.10,000 15 février 1995.10,000 15 février 1996.11,000 15 février 1997.12,000 15 février 1998.13,000 15 février 1999.15,000 15 février 2000.16,000 15 février 2001.17,000 15 février 2002.18,000 15 février 2003.19,000 15 février 2004.21,000 15 février 2005.23,000 15 février 2006.25,000 15 février 2007.27,000 15 février 2008.29,000 15 février 2009.32,000 15 février 2010.34,000 15 février 2011.38,000 15 février 2012 .40,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à L'Epiphanie.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas racbetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $427,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortisement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de Saint-Roch-de-l'Acbigan s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.amount less than $40,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table sappearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15, 2012 of the renewable part hereinafter mentioned.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of February 15, 1992 in the amount of $427,000 includes a balance of $419,000 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Year Capital February 15, 1993.$ 9,000 February 15, 1994.10,000 February 15, 1995.10,000 February 15, 1996.11,000 February 15, 1997.12,000 February 15, 199S.13,000 February 15, 1999.15,000 February 15, 2000.16,000.February 15, 2001.17,000 February 15, 2002.18,000 February 15, 2003.19,000 February 15, 2004 .21,000 February 15, 2005 .23,000 February 15, 2006 .25,000 February 15, 2007 .27,000 February 15, 2008 .29,000 February 15, 2009.32,000 February 15, 2010 .34,000 February 15, 2011.38,000 February 15, 2012.40,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at L'Epiphanie.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $427,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of St.Roch-de-l'Achigan agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days, upon, from and after February 15, 1972, without written authorization from the successful tenderer of the present issue. 238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1973, 10A' année, n° 8 Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement: 112-71 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue, lundi, le 31 janvier 1972, à 8 heures du soir, Sous-sol de l'Église, Rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan.comté de L'Assomption, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Roch-de-l'Achigan (Comté de L'Assomption), ce 4 janvier 1972.Le secrétaire-lrêsorier, Jean-Denis Beauchamps.Bureau du secrétaire-trésorier, 4S0, rue Principale, Case postale 150, St-Roch-de-l'Achigan, Comté de L'Assomption, P.Q.Téléphone: 832-3214, code 514.43982-o The said bonds will be issued pursuant to by-law: 112-71 \u2014 $500,000 \u2014 aqueduct, sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the council to be held on Monday, January 31, 1972, at 8:00 o'clock p.m., in the Church Basement, Principale Street, St.Roch-de-l'Achigan, County of L'Assomption, P.Q.The council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Roch-de-l'Achigan (County of L'Assomption), January 4, 1972.Jean-Denis Beauchamps, Secretary-Treasurer.Office of the Secretary-Treasurer, 480 Principale Street, Post Office Box 150, St.Roch-de-l'Achigan, County of L'Assomption, P.Q., Telephone: 832-3214, code 514.43982 La Commission scolaire régionale de PAmiante Siège social: 5, rue Notre-Dame Sud, Thetford Mines, Mégantic, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Orner St-Laurent, secrétaire-trésorier, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, Bureau du Directeur des Services administratifs, 5, rue Notre-Dame-Sud, case postale 29, Thetford Mines, comté de_Mégantic, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir.École secondaire de Thetford Mines, 581, rue Saint-Patrick, Thetford Mines, comté de Mégantic, P.Q., mercredi, le 2 février 1972, pour l'achat de $2,180,000 d'obligations pour la commission scolaire régionale de l'Amiante, comté de Mégantic, datées du 15 février 1972 et remboursables en série du 15 février 1973 au 15 février 1992 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 7%, ni supérieur à 8%, payable semi-annuellement les 15 février et 15 août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 février 1972.Tableau d'amortissement \u2014 $2,180,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 février 1973.$ 48,000 15 février 1974.51,000 15 février 1975.56,000 15 février 1976.60.000 15 février 1977.65,000 15 février 1978.70,000 15 février 1979.76,000 15 février 1980 .82,000 15 février 1981.88,000 15 février 1982 .95,000 15 février 1983.103,000 15 février 1984.111,000 15 février 1985.120,000 The Amiante Regional School Board Head Office: 5 Notre-Dame Street South, Thetford Mines, Mégantic, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Omer St-Laurent, Secretary-Treasurer, until 5:00 o'clock, p.m., at the Office of the Director of Administration Services, 5 Notre-Dame Street South, Post Office Box 29, Thetford Mines, County of Mégantic, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock, p.m., at the Thetford Mines High School, 581 St.Patrick Street, Thetford Mines, County of Mégantic, P.Q., on Wednesday, February 2, 1972, for the purchase of a bond issue of $2,180,000 for the Amiante Regional School Board, County of Mégantic, dated February 15, 1972 and redeemable serially from February 15, 1973 to February 15, 1992 inclusive, with interest at a rate of not less than 7%, nor more than 8%, payable half-yearly on February 15th and August 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 15, 1972.Redemption table \u2014 $2,180,000 \u2014 20 years Year Capital February 15, 1973.$ 48,000 February 15, 1974.51,000 February 15, 1975.56,000 February 15, 1976.60,000 February 15, 1977.65,000 February 15, 1978.70,000 February 15, 1979.76,000 February 15, 1980.82,000 February 15, 1981.88 000 February 15, 1982.95,000 February 15, 1983.103,000 February 15, 1984.111,000 February 15, 1985.120,000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.10k, No.2 239 15 février 1986.$129,000 15 février 1987.140,000 15 février 1988.151,000 15 février 1989.163,000 15 février 1990.1,76,000 15 février 1991.190,000 15 février 1992.206,000 La commission scolaire régionale de L'Amiante, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'Éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $206,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 février 1992.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations, au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé, payable au pair à Thetford Mines.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $206,000 et seul cet excédent sera rachetablc par anticipation, au pair, le 15 février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale de L'Amiante s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du February 15, 1986.$129,000 February 15, 1987.140,000 February 15, 1988.151,000 February 15, 1989.163,000 February 15, 1990.176,000 February 15, 1991.190,000 February 15, 1992.206,000 The Amiante Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Boards Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request tie Minister of Education to deposit in trust with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by the Minister of Education to the said corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $206,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 15.1992.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque payable at par at Thetford Mines.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $206,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on February 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Amiante Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian market within the sixty days upon, from and after February 15, 1972, 240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n° S 15 février 1972, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution du 22 juin 1971 \u2014 82,180,000 \u2014 construction de l'école polyvalente de Thetford Mines.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue, mercredi, le 2 février 1972, à 8 heures du soir.École secondaire de Thetford Mines, 581, rue Saint-Patrick, Thetford Mines, comté de Mégantic, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Thetford Mines (Comté de Mégantic), ce 5 janvier 1972.Le secrétaire-trésorier, Omer St-Laurent.Bureau du Directeur des Services administratifs.5, rue Notre-Dame Sud, Case postale 29, Thetford Mines, Comté de Mégantic, P.Q.Téléphone: 338-4565, code 418.43979-o without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution of June 22, 1971 \u2014 $2,180,000 \u2014 construction of the Thetford Mines Polyvalent School.Tenders will be opened and considered at a meeting of the school commissioners to be held on Wednesday, February 2, 1972, at 8:00 o'clock, p.m., at the Thetford Mines High School, 581 St.Patrick Street, Thetford Mines, County of Mégantic, P.Q.The school commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Thetford Mines (County of Mégantic), January 5, 1972.Omer St-Laurent, Secretary-Treasurer.Office of the Director of Administration Services, 5 Notre-Dame Street South, Post Office Box 29, Thetford Mines, County of Mégantic, P.Q.Telephone: 338-4565, code 418.43979 Vente par licit at ion Canada \u2014 Province de Québec District de Richelieu Cour Supérieure, ( T ÉANDRE CHAGNON, rentier.No 20-977.S -L-' demeurant et résidant à Ver-' chères, district de Richelieu, demandeur, vs VICTOR CHAGNON, de Verchères, district de Richelieu, défendeur.Licitation forcée Suivant jugement rendu en cette cause le 10 décembre 1971.« Le lot 198-43 de figure trapézoïdale, borné au nord-ouest par la route No 3, vers le nord-est par le résidu non divisé du lot No 198, vers le sud-est par le lot No 198-45, vers le sud-ouest par le lot No 198-44, mesurant trente-quatre pieds et six pouces (34'6\") de largeur dans la ligne sud-est, par cinquante-huit pieds et trois pouces (58'3\") de profondeur dans sa ligne nord-est, et soixante-sept pieds et huit pouces (67'8\") de profondeur dans sa ligne sud-ouest, contenant une superficie de deux mille cent soixante-douze pieds carrés (2,172 p.c), mesure anglaise.Le lot 198-45, de figure trapézoïdale, borné vers le sud-ouest par le lot 198-33 rue, vers le nord-ouest par les lots Nos 198-43 et 198-44, vers le nord-est par le lot No 198-46, mesurant cinquante-neuf pieds et trois pouces (59'3\") de largeur par quatre-vingt trois pieds et six pouces (83'6\") de profondeur dans sa ligne nord-ouest et quatre-vingt cinq pieds et sept pouces (85'7\") de profondeur dans sa ligne sud-est, contenant une superficie de cinq mille neuf pieds carrés, (5)009 p.c), mesure anglaise, des plans et livres de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Verchères.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Verchères, situé à Verchères, le VINGT-CINQUIÈ- Sale by Licitation Canada \u2014 Province of Québec District of Richelieu Superior Court, ( T ÉANDRE CHAGNON, annui-No.20-977.\\ *^ tant, domiciled and residing at ' Verchères, district of Richelieu, plaintiff, vs VICTOR CHAGNON, district of Richelieu, defendant.Forced licitation Following the judgement rendered in this case on December 10, 1971.\"Lot 198-43 of a trapezoidal configuration, bounded on the northwest by Highway No.3, on the northeast by the non subdivided remainder of lot No.198, on the southeast by lot No.198-45, on the southwest by lot No.198-44, measuring thirty-four feet, six inches (34'6\") in width on the southeast line by fifty-eight feet, three inches (58'3\") in depth on its northeast line, sixty-seven feet, eight inches (67'8\") in depth on its southwest line, containing two thousand one hundred and seventy-two square feet (2,172 sq.ft.), English measure.Lot 198-45 of a trapezoidal configuration, bounded on the southwest by lot 198-33, street, on the northwest by lots Nos 198-43 and 198-44, on the northeast by lot No.198-46 measuring fifty-nine feet, three inches (59'3\") in width by eighty-three feet, six inches (83'6\") in depth on its northwest line and eighty-five feet, seven inches (85'7\") in depth on its southwest line, containing five thousand and nine square feet, (5,009 sq.ft.), English measure, in the plan and book of reference of the official cadastre of the parish of Verchères.\" To be sold at the county of Verchères, registry office, situated at Verchères, on the TWENTY-FIFTH day QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January IB, 1973, Vol.104, No.3 241 ME jour de l'après-midi.FEVRIER 1972, à DEUX heures de Bureau du Shérif, Sorel, le 30 décembre 1971.Le shérif ad-hoc, Claude Hamelin.43992-0 of FEBRUARY, 1972, at TWO o'clock in the afternoon.Claude Hamelin, Sheriff's Office, Sheriff Ad-hoc.Sorel, December 30, 1971.43992 Ventes par Shérifs Sheriffs' Sales AVIS PUBLIC, est par le présent donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs, tels que mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ARTHABASKA ARTHABASKA Canada \u2014 Province de Québec District d'Arthabaska A T\\r JEAN-LOUIS ST-HILAIRE, \\ médecin-chirurgien, résidant et Cour Provinciale, i No.7781.I pratiquant à Princeville, district d'Arthabaska, demandeur vs RONALD ROUSSEAU, 56 rue Mailhot, Princeville, district d'Arthabaska, défendeur.« Un terrain situé dans la ville de Princeville, connu et désigné au cadastre officiel revisé et amendé dans le village de Princeville, comme étant la redivision dix-neuf de la subdivision dix du numéro originaire deux cent quarante-huit (248-10-19) avec bâtisses et servitudes.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement, 33 rue Laurier à Arthabaska, le DIX-HUITIÈME jour de FÉVRIER 1972, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, 44006-o J.G.Boissonnault.BEAUH ARNOIS De Terris District de Beauharnois Cour Provinciale, ( OOCIÉTÉ DE FINANCEMENT No 13-900.1S v tic y PRESTIGE LTÉE, corps poli-¦ tique dûment incorporé ayant une place d'affaire à Lacolle, district d'Iberville, Québec, demanderesse, contre CHARLES ROBERTS & JUDY ROBERTS, défendeurs conjoints et solidaires.« Ce certain emplacement vacant de forme irrégulière sis et situé dans le cinquième rang du canton d'Hemmingford, connu et désigné comme faisant partie du lot numéro cent quatre-vingt-quatre D (p.184-D) aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton situé immédiatement au sud du lot numéro cent quatre-vingt quatre C (184-C) dudit cinquième rang aux plan et livre de renvoi officiels, et situé entre la nouvelle route, route rurale No 36 et l'ancienne, mesurant environ mille trois cent vingt pieds (1320') sur son côté ouest au long de ladite nouvelle route selon Canada \u2014 Province of Québec District of Arthabaska Provincial Court, / TV.JEAN-LOUIS ST-HTLAIRE, No.7781.\\ surgeon-physician, residing and I practicing in Princeville, district of Arthabaska, plaintiff, vs RONALD ROUSSEAU, 56 Mailhot Street, Princeville, district of Arthabaska, defendant.\"A lot of land situated in the town of Princeville, known and designated in the revised and amended official cadastre for the village of Princeville as being redivision nineteen of subdivision ten of original number two-hundred and forty-eight (248-10-19) with the buildings and servitudes.\" To be sold at the Registry Office, 33 Laurier Street, in Arthabaska, on the EIGHTEENTH day of FEBRUARY, 1972, at TEN o'clock in the forenoon.J.G.Boissonnault, 44006-o Assistant Sheriff.BEAUHARNOIS De Terris District of Beauharnois Provincial Court, ( COCIÉTÉ DE FINANCEMENT No.13-900.< O PRESTIGE LTÉE, a body t politic and incorporated having a place of business at Lacolle, district of Iberville, Québec, plaintiff, vs CHARLES ROBERTS & JUDY ROBERTS, jointly and severally defendants.\"That certain vacant emplacement of irregular figure lying and situate in the township of Hemming-ford, in the fifth range thereof, known and designated as being a part of lot number one hundred and eighty-four D (P.184-D) of the official plan and book of reference of the said township, located immediately south of lot number one hundred and eighty-four C 184-C) of the said fifth range of the said official plan and book of reference, and located between the new highway, Rural Route No.36, and the old road or highway, measuring about one thousand three hundred and 242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n\" 2 appropriation par le ministère de la Voirie de la province de Québec, en vertu d'un acte de vente enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Huntingdon sous le numéro 46472 et étant quelque peu plus longue que ledit métrage sur sa ligne de côté est ou sud-est au long de l'ancienne route ou chemin, sur environ cent dix pieds (110') de largeur sur sa ligne de côté nord le long de la ligne separative entre le lot numéro cent quatre-vingt-quatre D (184-D) et le lot numéro cent quatre-vingt-quatre C (184-C) toutes deux dudit cinquième rang desdits plan et livre de renvoi officiels, sur une largeur.dans sa ligne de côté sud d'environ vingt pieds (20'), toutes ces dimensions étant de mesure anglaise et plus ou moins.Ladite parcelle de terrain étant bornée comme suit : En façade, à l'ouest par ladite nouvelle route telle qu'acquise par le ministère de la Voirie en vertu d'un acte de vente enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Huntingdon sous le numéro 46472, à l'arrière, à l'est ou sud-est par l'ancienne route ou chemin public, d'un côté au nord par le lot numéro cent quatre-vingt-quatre C (184-C) dudit cinquième rang auxdits plan et livre de renvoi officiels et appartenant à Hervé Duquette, et l'un des côtés restant au sud par une autre partie dudit lot numéro cent quatre-vingt-quatre D (p.184-D), propriété du vendeur, le tout ainsi qu'indiqué par une esquisse de ladite propriété immobilière y attachée, tracée en rouge et reconnue comme étant authentique et signée aux fins d'identification par les parties intéressées et le notaire soussigné.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Huntingdon, à Huntingdon, le VINGT-QUATRIÈME jour de FÉVRIER 1972, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Salaberry de Valleyfield, Thérèse Leblanc.le 28e jour de décembre 1971.43986 twenty feet (1320') on its west side along said new highway as appropriated by the Roads Department of the Province of Québec under sale registered in the Huntingdon County Registry Office under the No.46472, and somewhat more than said footage on its east or southeast side line along the old road or highway, by about one hundred and ten feet (110') in width on its north side line along the division line between said lot number one hundred and eighty-four D (184-D) and lot number one hundred and eighty-four C (184-C) both of the said fifth range of the said official plan and book of reference, by a width on its south side line of about twenty feet (20'), all measurements being English measure and more or less: bounded said parcel of land as follows: In front to the west by said new road or highway as acquired by the Department of Roads under deed registered in the Huntingdon County Registry Office under number 46472.in rear to the east or southeast by the old road or public highway, on one side to the north by lot number one hundred and eighty-four C (184-C) of the said fifth range of the said official plan and book of reference belonging to Hervé Duquette, and one the remaining side to the south by another part of said lot number one hundred and eighty-four D (P.184-D), the property of the vendor, the whole as shown on a sketch of the said immoveable property attached hereto, outlined in red, acknowledged true, and signed for identification by the parties hereto and the undersigned notary.\" To be sold at the Registry Office of Huntingdon Division, in Huntingdon on the TWENTY-FOURTH day of FEBRUARY, 1972, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Thérèse Leblanc, Salaberry de Valleyfield, Assistant Sheriff.the 28th day of December 1971.43986-0 Bonis et de Terris District de Beauharnois Cour Provinciale, f A MIRON & FRÈRE INC., No 10 284.\\ corporation légalement ' constituée opérant et ayant une place d'affaires à Salaberry de Valleyfield, district de Beauharnois, demandeur, vs JOSEPH B AILLA R-GEON, domicilié en la paroisse St-Timothée, district de Beauharnois, défendeur.« Un lot de terre connu et désigné sous le numéro quatorze de la subdivision du lot originaire numéro cent cinquante-six (156-14) du cadastre de la paroisse St-Timothée, avec les bâtisses dessus construites, et en particulier une maison portant le numéro civique 223 du Boulevard Hébert, St-Timothée, district de Beauharnois ».Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Beauharnois, à Beauharnois, le DIX-SEPTIÈME jour de FÉVRIER 1972, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Salaberry de Valleyfield, Thérèse Leblanc.le 4e jour de janvier 1972.44009-o Bonis et de Terris District of Beauharnois Provincial Court, J A MIRON & FRÈRE INC., a No.10 284.\\ iV.lawful corporation operat-l ing and having a place of business in Salaberry de Valleyfield, district of Beauharnois, plaintiff, vs JOSEPH BAILLARGEON, domiciled in the parish of St.Timothée, district of Beauharnois, defendant.A lot of land known and designated under number fourteen of the subdivision of original lot number one hundred and fifty-six (156-14) of the cadastre for the parish of St.Timothée, with the buildings constructed thereon, and particularly a house at number 223 Hébert Boulevard, St.Timothée, district of Beauharnois\".To be sold at the Beauharnois Division Registry Office, in Beauharnois, on the SEVENTEENTH day of FEBRUARY, 1972, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Thérèse Leblanc, Salaberry de Valleyfield, Assistant Sheriff.the 4th day of January, 1972.44009 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 243 HAUTERIVE Canada \u2014 Province de Québec District de Hauterive Cour Provinciale, ( \\ if AURICE AUTORAMA INC., de Baie Comeau < J-VJ- demandeur, m LOUIS JEAN No 10097.t défendeur.Affectant le lot dix (10) rang de la Pointe aux Outardes, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du Canton Manicouagan, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, sauf à distraire partie vendue à Horace Nadeau suivant enregistrement no: 46947 (132' de largeur), partie appartenant à Roger Ross suivant enregistrement no: 65787 (70' x 125'), partie appartenant à Charles Tremblay suivant enregistrement no: 56506 (50' x 150'), partie appartenant à Nelson Boulay suivant enregistrement no: 65242 (160'xl50').Pour être vendu au Bureau du régistrateur de la première division d'enregistrement du comté de Saguenay, au Palais de justice de Baie Comeau, MARDI, le QUINZIÈME jour de FÉVRIER 1972 à DIX heures TRENTE de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif-adjoint, Raymond Tremblay Baie Comeau, ce 15 janvier 1972.43987-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Cour Provinciale, / T A COMMISSION DU SALAI-à savoir: 1 *-> RE MINIMUM, était deman-No 72-703.j deresse.Constant Panus, Demi-' trios Panagiotopoulos et Grégoire Panagiotopoulos, étaient les défendeurs conjoints et solidaires.Commission du Salaire Minimum, corps politique légalement constitué, en vertu du chapitre 144, S.R.Q.1964, ayant une place d'affaires au 2875 Boul.Laurier, Ste-Fov, district de Québec, contre 1)1-MITRIOS PANAGIOTOPOULOS, domicilié au 2056 Chemin Ste-Foy, Ste-Foy, district de Québec.« Le lot subdivision 3 du lot originaire 119 du cadastre officiel de Ste-Foy, et immeuble dessus construit.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 10 avenue Chauveau.Québec, le QUINZIÈME jour de FÉVRIER 1972 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 11 janvier 1972.44020-o HAUTERIVE Canada \u2014 Province of Québec District of Hauterive Provincial Court, f \"\\ if AURICE AUTORAMA INC., of Baie Comeau.S -M- plaintiff, vs LOUIS JEAN, No.10097.'defendant.Concerning lot ten (10) Pointe aux Outardes Range, in the official plan and book of reference for the Township of Manicouagan, with buildings constructed thereon, circumstances and dependencies, save and to withdraw the part sold to Horace Nadeau pursuant to registration No.46947 (132' in width), the part belonging to Roger Ross pursuant to registration No.65787 (70' x 125'), the part belonging to Charles Tremblay pursuant to registration No.56506 (50' x 150'), the part belonging to Nelson Boulay pursuant to registration No.65242 (160' x 150').To be sold at the Office of the Registrar for the First Registration Division of the County of Saguenay, at the Baie Comeau Court House, on TUESDAY, the FIFTEENTH day of FEBRUARY, 1972, at TEN THIRTY o'clock in the forenoon.Raymond Tremblay, Assistant Sheriff's Office, Assistent Sheriff.Baie Comeau, January 15, 1972.43987 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Provincial Court, ( -\"THE MINIMUM WAGE COM-Towit: ) -\u2022¦ MISSION, plaintiff.Constant No.72-703.) Panus, Demitrios Panagiotopoulos t and Grégoire Panagiotopoulos, joint and several defendants.The Minimum W'age Commission, body politic, lawfully incorporated under chapter 144, R.S.Q., 1964, having a place of business at 2875 Laurier Boulevard, St.Foy, District of Québec, against DIMITRIOS PANAGIOTOPOULOS, domiciled at 2056 St.Foy Road, St.Foy, District of Québec.\"Lot subdivision 3 of original lot 119 of the official cadastre of St.Foy and the immoveable constructed thereon.\" To be sold at the Québec Registry Office, 10 Chauveau Avenue, Québec, the FIFTEENTH dav of FEBRUARY, 1972, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, January 11, 1972.44020 244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 104' année, n° 2 ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Roberval En la Cour Supérieure ( T ES PRÉVOYANTS DU de Roberval, ) *-' CANADA, corporation No 34,807.) légalement constituée, ayant ' son siège social dans les ville et district de Montréal, demanderesse, vs M.GASTON I50ILY, demeurant au numéro 1720 de la rue Gobert, Ville Les Saules, P.Q., défendeur.Avis de vente « Un emplacement mesurant quatre-vingt-un pieds et trente-six centièmes de front ou largeur sur cent pieds de profondeur (81.36' x 100.0'), mesures anglaises, comprenant le lot connu et désigné sous le numéro cinq cent douze (lot 512), mesurant quatre-vingts pieds de front ou largeur sur cent pieds de profondeur (80.0' x 100.0') et le pied et trente-six centièmes nord-est du lot numéro cinq cent treize (1.36' N.E.lot 513), aux plan et livre de renvoi officiels de la revision cadastrale de la Ville de Mistassini, partie du canton Dolbeau, division d'enregistrement Lac St-Jean-Ouest, avec bâtisses dessus construites, appartenances et dépendances.Le pied et trente-six centièmes nord-est dudit lot numéro cinq cent treize (1.36' lot 513) borné: au sud-est, par l'avenue Boivin portant le numéro cadastral cinq cent quinze, en front; au nord-ouest, en arrière, par le lot numéro quatre-cent quatre-vingt-cinq; en profondeur, tenant, au nord-est, audit lot numéro cinq cent douze et, enfin, au sud-ouest, par le résidu dudit lot numéro cinq cent treize.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la Division d'enregistrement Lac St-Jean-Ouest à Roberval, district de Roberval, le DIX-SEPTIÈME jour de FÉVRIER 1972 à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif, Palais de Justice, Léon-Maurice La voie.Roberval, le 28 décembre 1971.43988-0 SAINT-MAURICE Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Cour Provinciale, jp REDIT LORAINE LTÉE, No 02-384573-71.< corporation légalement cons- ' tituée, ayant son siège social et prindipale place d'affaires à Montréal-Est, district de Montréal, demanderesse vs WILFRID CAMIRE, de Montréal, district de Montréal, défendeur.« Un emplacement faisant partie de l'ancien territoire de la base de radar Parent connu et désigné comme étant le lot numéro dix-neuf de la resubdivision du lot numéro trois de la subdivision du lot originaire ROBERVAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Roberval In the Superior Court l T ES PRÉVOYANTS DU of Roberval, ; J-' CANADA, a lawful cor-No.34,807.J poration, having its head office \\ in the City and District of Montreal, plaintiff, vs MR.GASTON BOILY, residing at 1720 Gobert Street, Town of Les Saules, P.Q., defendant.Notice of Sale \"An emplacement measuring eighty-one and thirty-six hundredths feet in front or width by one hundred feet in depth (81.36' x 100.0'), English measure, comprising the lot known and designated under number five hundred and twelve (lot 512), measuring eighty feet in front or width by one hundred feet in depth (80.0' x 100.0') and one and thirty-six hundredths feet northeast of iot number five hundred and thirteen (1.36' N.E.lot 513), in the official plan and book of reference of the cadastral revision of the Town of Mistassini, part of the Township of Dolbeau, Lake St.John West Registration Division, with buildings constructed thereon, appurtenances and dependencies.The one and thirty-six hundredths feet northeast of the said lot number five hundred and thirteen (1.36' lot 513) bounded: on the southeast, by Boivin Avenue, bearing cadastral number five hundred and fifteen, in front; on the northwest, in the rear, by lot number four hundred and eighty-five; in depth, adjacent, on the northeast, to said lot number five hundred and twelve and, lastly, on the southwest, by the remaining part of said lot number five hundred and thirteen.\" To be sold at the Lake St.John West Division Registry Office in Roberval, District of Roberval, on the SEVENTEENTH day of FEBRUARY, 1972, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Léon-Maurice Lavoie, Court House, Sheriff.Roberval, December 28, 1971.43988 S A I N T - M A U R I C E Canada \u2014 Province of Québec District of Montreal Provincial Court, l CRÉDIT LORAINE LTÉE, a No.02-384573-71.\\ yJ lawful corporation having V its head office and principal place of business in Montreal-East, district of Montreal, plaintiff, vs WILFRID CAMIRE of Montreal, district of Montreal, defendant.\"An emplacement being part of the former territory of the Parent Radar Base, known and described as being lot number nineteen of the resubdivision of lot number three of the subdivision of original lot Block QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 15, 1972, Vol.104, No.2 245 Bloc «A» (Bloc «A»-3-19) aux plan et livre de renvoi officiels du canton Dandurand dans le comté de Laviolette, mesurant 44.50 pieds de largeur en front et 45.69 pieds de largeur en arrière par une profondeur de 146.06 pieds dans une ligne et 150 pieds dans l'autre ligne et ayant une superficie de 6,658 pieds carrés.Avec toutes les bâtisses dessus érigées et notamment celle portant le No 25 avant front sur la rue portant le No A-10.Ainsi que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble, avec droit de passage en commun avec tous autres ayant droit dans les rues desservant ledit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de La Tuque.582 rue Commerciale, MERCREDI le SEIZIÈME jour de FÉVRIER 1972, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, Bureau du shérif, René Boisvert.Shawinigan, 7 janvier 1972.44010-o \"A\" (Block \"A\"-3-19) in the official plan and book of reference of the Township of Dandurand, in the County of Laviolette, measuring 44.50 feet in width in front and 45.69 feet in width in the rear, by a depth of 146.06 feet in one line and 150 feet in the other line, containing 6,658 square feet.With all buildings erected thereon, notably that numbered 25 fronting on the street numbered A-10.As the whole now subsists with active and passive, apparent or unapparent servitudes attached to the said immoveable, with a common right of way with all other owners on the streets serving the said immoveable.\" To be sold at the La Tuque Registry Office, 582 Commerciale Street, on WEDNESDAY, the SIXTEENTH day of FEBRUARY, 1972, at ELEVEN o'clock in the forenoon.René Boisvert, Sheriff's Office, Sheriff.Shawinigan, January 7, 1972.44010 246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1973, 10W année, n° g INDEX No S Partiel: avis juridiques \u2014 Parti: Juridical notices ASSOCIATION COOPÉRATIVE COOPERATIVE ASSOCIATION Club coopératif de consommation d'Amos (Formation).218 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Ryan, James Arthur.226 Tohme, Tohme Youssef.226 COMPAGNIES -LOI DES Demandes d'abandon de charte COMPANIES ACT Applications for Surrender of Charter Auger (H.) Welding Co.Ltd.210 Caplan (J.) and Co.Ltd.208 Consol Investments Corp.206 Delta Services Inc.207 Drummond Speedway.207 Drummond Trading Ltd.207 Druna Investment Corp.207 Entreprises Fleury inc.(Les).208 Flanders Equities Ltd.207 Fonds Richelieu inc.209 Foyer Bourbonnais inc.209 Hi-Quality Construction Inc.210 Hunter Douglas Limited.210 L & W Realties Ltd.209 Lafayette Shoe Manufacturing Company Limited .208 Montreal Cotton Company (The).208 Nettoyeurs Swan inc.209 Rawin (S.J.) Ltd.208 Ronmur Slacks Ltd.209 Ross Investment Corp.210 Ruby Foo's Farm Inc.210 Sunset Investment Corp.211 Swan Cleaners Inc.209 Dissoutes Dissolved Ameublement Thetford inc.93 Birkdale Agencies Inc.93 Blocs de Ciment Rouville inc.93 British Holdings Limited.93 Brite Home Construction Inc.93 Combustion Utilities Corp.of Québec.94 Commercial & Technical Computer Services (Quéliec) Limited.94 Compagnie de Placements d'Ibcrville limitée (La).94 Compagnie de Prêts Régionale ltée (I-a).94 Créations Charmantes inc.94 Dorchester Transport U.S.Inc.94 Erie Service & Equipment Ltd.95 Goodfellow (Charles) Lumber Company Ltd.95 Kirouac (.LA.) limitée.95 I .i.i11i- Construction Inc.95 Manny Realty Inc.95 Modem Trading Limited.95 Ostiguy (A.B.) limitée.96 Picard (Thérèse) inc.96 Resluuraiil les Rouets de Laie inc.90 St.Maurice Waste Paper & Metal Co.Inc.96 Shanedling Company Ltd.96 Thetford Furniture Inc.93 Tri Citv Investments Corp.Ltd.97 United Textiles Ltd.97 Diver* Miscellaneous Alamo Electric Ltd.(Nom-Name ch.).212 Bonbon Expert ltée (Le) (Dir.).211 Centre d'accueil Laurentien (Dir.).212 Club de l'âge d'or de Waterloo inc.(Dir.) (Règl.-By-laws).211 Création prothèse capillaire ltée (Nom-Name ch.)._.212 École de natation Régent Lacoursière inc.(Nom ch.)____.212 Éditions Vaudreuil inc.(Dir.).212 Expert Candy Ltd.(Dir.).211 Gratton (Jean-Paul) inc.(Nom-Name ch.).212 Head & Hands Inc.(Règl.-By-laws).213 Industries Val Mar inc.(Les) (Nom-Name ch.) 213 Inter-Ex inc.(Dir.).213 lacoursière (Régent) Swim School Inc.(Name ch.).212 Librairie Qualité ltée (Nom ch.).213 Marwest Hotel Company Ltd.(Nom-Name ch.).214 McGuire Press Co.Limited (Dir.).213 O'Brien Gold Mines Limited (Dir.).213 Ottawa Ski Club, Incorporated (Règl.-Bylaws).214 Placements Grenache inc.(Dist.aelif-assets) 211 Plant National Industries (Canada) Ltd.(Dir.) 214 Plant NationalIndustries(Montreal)Ltd.(Dir.) 214 Plurimar inc.(Dir.).208 Prographis Inc.(Dir.).214 Quality Book Distributors Ltd.(Name ch.).213 Résidences de la Mauricie inc.(Les) (Dir.) 214 Rivière-du-Loup Câble T.V.ltée (Dir.)____ 214 Sieges sociaux Head Offices Beaton-Saulnier inc.216 Contractors Supplies Limited.216 Daigle Aqua inc.216 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, January 16, 1972, Vol.m.No.2 247 Sièges sociaux Head Offices (suite) (continued) Dandurand (R.) & Associés inc.216 Distributeurs de livres de qualité ltée.215 Dubreuil - Lefebvre - Roy inc.215 Entreprises Ginelain inc.215 Fédération des écoles privées de la province de Québec inc.215 Federation of Private School of the Province of Québec Inc.215 Immeubles Daigle inc.(Les).217 Impression B.T.V.inc.217 Inter-Ex Inc.215 Location T.V.Sorel inc.217 Miller Agencies Ltd.217 Quality Book Distributors Ltd.215 Société des consultants en administration hospitalière ltée (La).216 Tako Corporation.217 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES \u2014 Loi de la ACT Conjpagnie locale de téléphone de Ham-Nord (La).220 Entreprises Christian inc.(Les).220 Placements Guy Fortier inc.(Les).221 Sigma inc.221 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Maple-Grove, ville-towu (L.P.).225 St-Éustache, ville-town (Fusion volontaire- voluntary amalgamation).221 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Lake of Two Mountains (Prot.) (Dem.-Appl.) 217 Institutions Finalcial financières Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance: Insurance: Internationale, compagnie d'assurance-vie (L') (L.P.).220 International Life Insurance Company (The) (L.P.).220 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Holland, canton-township.205 Jonquiere, canton-township.205 Jonquiere, canton-township.205 Laprairie de la Magdeleine, par.205 Letellier, canton-township.205 Pointe-Claire, par.206 Ste-Anne de la Pocatiére, par.206 St-Laurent, par.206 Société d'habitation Québec Housing du Quebec Corporation Moisie, munie.(Programme de renovation-Renewal Program).219 Municipal Housing Bureau of Shefford (L.P.) 219 Office municipal d'habitation de Shefford (L.P.).219 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Amiaute, c.s.r.-r.s.b.238 Ancienne-Lorette, c.s.-s.c.233 Bagotville, par.229 Châteauguay, c.s.-s.c.(Erratum).226 Pointe-aux-Trembles, cité-city.227 Ste-Agathe-des-Monts, ville-town.231 St-Roch-de-l'Achigan, par.236 SYNDICATS COOPERATIVE PROFESSIONNELS SYNDICATES Association des employés de la Laurentienne (Const.-Inc.).218 Association des Néphrologues du Québec i (Const.).218 Association of Nephrologists of Québec (Inc.).218 Syndicat des employés de l'abattoir Ouellet inc.(Le) (Const.-Inc.).219 VENTES SALES Licitation Licitation Chagnon vs Chagnon.240 Par Shérifs By Sheriffs Arthabaska Arthabaska St-Hilaire vs Rousseau.241 Beauharnois Beauharnois Marion (A.) & Frère inc.VS Baillargeon.242 Société de financement prestige ltée vs Roberts 241 Hautcrive llauterive Maurice Autorama inc.vs Jean.243 Québec Québec Commission du salaire minimum vs Panagiotopoulos.243 Minimum Wage Commission us Panagiotopoulos.243 Roberval Roberval Prévoyants du Canada (Les) vs Boily.244 Saint-Maurice Saint-Maurice Crédit Loraine ltée vs Canure.244 248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1972, 10k' année, n° 2 Taxes Ta.tes Beauce, comté-county.97 Bonaventure, comté-county.113 Brome, comté-county.106 Châteauguay, comté-county.119 Compton, comté-county.133 Frontenac, comté-county.103 Joliette, comté-county.184 Lac St-Jean-Ouest, comté.136 Lake St.John West, county.136 Laprairie, comté-county.174 Lévis, comté-county.141 Matane, comté-county.154 Missisquoi, comté-county.100 Montcalm, comté-county.164 Papineau, comté-county.196 Richmond, comté-county.98 St-Hyacinthe, comté-county.156 Saint-Jean, comté.'28 St.Johns, county.128 Shefford, comté-county.150 Stanstead, comté-county.146 Soulanges, comté-county.161 Témiscamingue, comté-county.130 Témiscouata, comté-county.142 Vaudreuil.comté-county.158 QUÉBEC OFFICIAI.GA/ETTE.January 15.1972.Vol 104.Su.2_ 249 LOIS ET RÈGLEMENTS\tLAWS AND REGULATIONS Arrêtés en conseil\tOrder in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4333 Québec, le 22 décembre 1971 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant l'adoption d'un règlement relatif à la signature de certains documents du ministère des Affaires sociales.Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi du ministère des Affaires sociales (1970.chapitre 42), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre, ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil publié dans la Gazelle officielle du Québec; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le docteur Martin Laberge.directeur de la direction de l'agréement des établissements à signer certains documents du ministère des Affaires sociales.Il est ordonne en conséquence sur la recommandation du ministre des Affaires sociales: Que soit adopté le règlement suivant: Le docteur Martin Laberge, directeur de la direction de l'agréement des établissements, est autorisé à signer avec la même autorité que le ministre les permis d'exploitation des établissements relevant du ministère des Affaires sociales.Que le présent règlement soit publié dans la Gazelle officielle du Québec.Le Greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.44013-O Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4344 Québec, le 22 décembre 1971 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant les pouvoirs de la Régie des Loteries et Courses en matière de systèmes de loteries et les modalités selon lesquelles des licences peuvent être délivrées.Il est ordonné, sur la proposition du Ministre de la Justice: LR-3i Order in Council Executive Council Chamber Numéro 4333 Québec, December 22.1971 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the making of a regulation respecting the signing of certain documents of the Social Affairs Department.Whereas under section 8 of the Social Affairs Department Act (1970.chapter 42).no deed, document or writing shall bind the Department or be attributed to the Minister unless it is signed by him.the Deputy Minister or an officer and only, in the case of the latter, to the extent determined by regulation of the Lieutenant-Governor in Council published in the Québec Official Gazelle; Whereas it is expedient to authorize Dr.Martin Laberge.director of the establishments certification branch, to sign certain documents of the Social Affairs Department.It is ordered, consequently, on the recommendation of the Minister of Social Affairs: That the following regulation be made: Dr.Martin Laberge.director of the establishments certification branch, is authorized to sign, with (he same authority as the Minister, permits to operate establishments under the jurisdiction of ihe Social Affairs Department.That this regulation be published in the Québec Official Gazelle.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.44013-O Order in Council Executive Council Chamber Number 4344 Québec, December 22, 1971 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the powers of the Régie des Loteries et Courses as regards lottery schemes and the terms and conditions for the issue of licences.It is orderld, upon the recommendation of the Minister of Justice: 250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15janvier 1972.104eannée.n'2 Que la dale d'entrée en vigueur des articles 29, 31 et 32 du règlement numéro I relatif aux licences pour systèmes de loteries, fixée au 1er septembre 1971 ou à toute autre date par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1435, en date du 21 avril 1971.et reportée au 1er janvier 1972 en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2979.en date du 25 août 1971, soit de nouveau reportée au 1er juin 1972.Le Greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.440I4-o That the date of coming into force of sections 29.31 and 32 of regulation number I respecting licences for lottery schemes, fixed at the 1st of September 1971 or any other date by the Lieutenant-Governor in Council under Order in Council Number 1435 dated 21 April 1971.and extended to the 1st of January 1972 under Order in Council number 2979 dated 25 August 1971, be again extended to the 1st of June 1972.Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council.44014-o Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4371 Québec, le 22 décembre 1971 Présent: Le lieutenanl-gouverneur en conseil.Concernant le transfer! de fonctionnaires du ministère des finances à l'Office de planification et de développement du Québec.Attemil que des fonctionnaires du Bureau du contrôleur des finances ont été postés au ministère du Conseil exécutif pour fournir un service appelé service des finances, à l'Office de développement de l'est du Québec, qui fait mainlenant parlie intégrante de l'Office de planification et de développement du Québec.Attendi Qu'il est maintenant jugé approprié que certains de ces fonctionnaires soient mutés au nouveau service financier de l'Office de planification et de développement du Québec.ii.est ordonné en conséquence, sur la recommandation du minisire des finances, en vertu de l'article 7 de la Loi de l'exécutif (SR.1964 ch.9) et l'article 63 de la Loi de la fonction publique: Qle les fonctionnaires et leurs postes désignés à l'annexe \" A o des présentes, soient mutés du ministère des finances à l'Office de planification et de développement du Québec.Que les crédits prévus au budget du ministère des finances pour le traitement de ces fonctionnaires soient transférés à l'article 5 au budget du ministère du Conseil exécutif.Que cet arrêté en conseil prenne effet à compter de sa date.Le Greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.Poste 8606 8608 8609 Annexe « a » Nom Prénom Order in Council Executive Council Chamber Number 4371 Québec, December 22.1971 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the transfer of officers of the Finance Department to the Québec Planning and Development Bureau.Whereas certain officers of the office of the Comptroller of Finance have been assigned to the department of the Executive Council to provide a service called the Finance Service at the Eastern Québec Development Bureau which now forms an integral part of the Québec Planning and Development Bureau.Whereas it is now deemed appropriate that certain of such officers be transferred to the new Finance Service of the Québec Planning and Development Bureau.It is ordered, consequently, on the recommendation of the Minister of Finance, under section 7 of the Executive Power Act and section 63 of the Civil Service Act: \u2022 That the officers and positions mentioned in Schedule \"A\" hereto be transferred from the Finance Department to the Québec Planning and Development Bureau.That the credits provided for in the budget of the Department of Finance for the salaries of such officers be transferred to item 5 of the budget of the department of the Executive Council.That this order in council take effect on its date.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.44015-o Annexe \"a\" Fortin Jacob Paré Clement André D.Yvon Number 8606 8608 8609 Name Fortin Jacob Paré Given name Clément André D.Yvon QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.January IS.1972.Vol.104.No.2 251 8610 Amyot Byrne 8621 Carrier Roland 8622 Leclerc Paul 8623 Agent-vérificateur Audit agent 3 8661 Marcoux Denise 8663 Tremblay Andrée 8664 Paré Sylvie 44015-o Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4419 Québec, le 31 décembre 1971 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans le Territoire de la Région de la Baie James.Attendu que la Société de Développement de la Baie James a pour objet de susciter le développement et l'exploitation des richesses naturelles qui se trouvent dans le Territoire; Attendu que le développement des ressources hydroélectriques sera effectué par une filiale de cette société; Attendu que l'aménagement de certaines rivières qui font partie du bassin Versant de la Baie James nécessite la construction d'ouvrages; Attendu que, pour la construction de ces ouvrages, une grande quantité de substances minérales employées principalement comme matériaux de construction sera nécessaire: Attendu que ces substances minérales employées principalement comme matériaux de construction pourraient être acquises par des particuliers qui jalonneraient les terrains contenant ces substances minérales; Attendu Qu'il y a lieu de prévenir tout jalonnement de nuisance dans les terrains susceptibles de contenir ces substances minérales: Attendu que, conformément au sous-paragraphe I de l'article 268 de la Loi des mines (S.Q.1965.chapitre 34), le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver et soustraire, par règlement, au jalonnement des terrains qui, dans son opinion, peuvent être requis ou nécessaires à l'aménagement des forces hydrauliques ou à toutes autres fins; Attendu que des études préliminaires permettent de délimiter les terrains susceptibles de contenir ces substances minérales.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Richesses naturelles: Que soit réservée et soustraite au jalonnement: 8610 Amyot Byrne 8621 Carrier Roland 8622 Leclerc Paul 8623 Agent-vérificateur Audit agent 3 8661 Marcoux Denise 8663 Tremblay Andrée 8664 Paré Sylvie Order in Council Executive Council Chamber Number 4419 Québec, December 31, 1971 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the withdrawal from staking of certain land in the Territory of the James Bay region.Whereas the objects of the James Bay Development Corporation are to promote the development and exploitation of natural resources in the Territory; Whereas the development of hydroelectric resources will be effected by a subsidiary of the Corporation; Whereas the development of certain rivers forming part of the James Bay watershed requires the construction of works; WHEREAS for the construction of such works a substantial quantity of mineral substances used mainly as construction material will be necessary: Whereas these mineral substances, used principally as construction material, may be acquired by individuals who might stake the land containing them: Whereas it is expedient to prevent all harmful staking in land likely to contain such mineral substances; Whereas in accordance with paragraph I of section 268 of the Mining Act (1965, chapter 34) the Lieutenant-Governor in Council may by regulation reserve and withdraw from staking land which in his opinion may be required or necessary for the development of water power or for any other purposes; Whereas preliminary studies allow a delimitation of the land likely to contain such mineral substances: It is ordered on the recommendation of the Minister of Natural Resources: That the following be reserved and withdrawn from staking: i.r-34 252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15janvier 1972.104eannée, n'2 Une étendue de terrain située dans le territoire d'Abi-tibi et plus particulièrement décrite comme suit: D'un point « A » situé à la jonction de la longitude 78°50' et de la rive sud de la rivière Nottaway; en direction sud astronomique jusqu'au point « B », intersection des coordonnés 50°30' et 78°50': en direction ouest astronomique, jusqu'au point « C », frontière Québec-Ontario; en direction nord, en suivant la frontière Québec-Ontario jusqu'au point « D », à l'intersection avec la rive sud de la baie de la Mouette; puis en suivant le rivage de la péninsule Ministikawa-tin jusqu'au point de départ.Cette étendue comprend une superficie approximative de 2,035 milles carrés.Le tout tel que tracé en rouge sur le plan B-1081 à l'échelle de 1:1,000,000, lequel plan est initiale par le sous-ministre des Richesses naturelles cl fait partie des archives de ce ministère.Que ce règlement ait force de loi dès sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Le Greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.440 I6-o A parcel of land situated in the territory of Abitibi.more particularly described as follows: From Point \"A\" situated at the meeting point of longitude 78°50' and the south shore of the Notlaway river: astronomically south to point \"B\".the intersection of the coordinates 50°30' and 78°50'; astronomically west to point \"C\".the Québec-Ontario boundary: northerly along lhat boundary to point \"D\".at ihe intersection with the south shore of Baie de la Mouette, then along the shore of the Ministikawatin peninsula to the starting point.f This parcel contains an area of approximately 2.035 square miles.The whole as outlined in red on map B-I08I, scale 1: 1.000,000.initialed by the deputy minister of Natu-ial Resources and forming part of the archives of that department.That this regulation have force of law upon its publication in the Québec Official Gazelle.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.44016-0 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 15.1972.Vol.104.No.2 253 Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 7 Québec, le 7 janvier 1972 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le boeuf musqué.Attendu que le paragraphe c) de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (Lois du Québec 1969.chapitre 58) stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone les catégories d'animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l'année ou les parties de la journée, pendant lesquelles la chasse est interdite à l'égard de ces catégories d'animaux: Attendu que le paragraphe c) de l'article I de ladite loi stipule que l'expression « gros gibier » signifie l'orignal, le chevreuil et le caribou ainsi que tout autre animal défini comme tel.par règlement; Attendu que des expériences d'acclimatation ont été entreprises dans le Québec, à l'égard du boeuf musqué, et qu'il y a lieu de protéger cet animal à l'année; Attendu Qu'il y a lieu de classer le boeuf musqué dans la catégorie des gros gibiers; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche d'adopter le Règlement concernant le boeuf musqué.Règlement concernant le boeuf musqué 1° Il est défendu de chasser le boeuf musqué à l'année dans tout le Québec.2\" Le boeuf musqué est classé dans la catégorie des gros gibiers.3° Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Le Greffier du Conseil exécutif.Julien Chouinard.44017-0 Order in Council Executive Council Chamber Number 7 Québec.January 7, 1972 Present: The Lieutenant-Governor in Council Respecting musk-oxen Whereas sub-paragraph c of section 77 of the Wildlife Conservation Act (Statutes of Québec.1969.chapter 58) provides that the Lieutenant-Governor in Council may divide the province of Québec into hunting zones and determine, within each zone or part of a zone, the classes of animals which may be hunted and the periods of the year or the parts of the day during which hunting for such classes of animals is prohibited; Whereas paragraph cof section 1 of that act provides that the expression \"big game\" means moose, deer, caribou and any other animal defined as such by regulation; Whereas acclimatization experiments have been carried out regarding musk-oxen in Québec and it is expedient to protect that animal the year round: Whereas it is expedient to classify musk-oxen as big game; It is ordered, on the recommendation of the Minister of Tourism, Fish and Game that the regulation on musk-oxen be made.Regulation respecting musk-oxen 1.It is forbidden to hunt musk-oxen the year round throughout Québec.2.Musk-oxen are classified as big game.3.This regulation shall come into force upon its publication in the Québec Official Gazette.Julien Chouinard.Clerk of the Executive Council.44017-o Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 8 Québec, le 7 janvier 1972 Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la réserve de Kipawa.Attendu que le paragraphe r) de l'article 77 de la Loi de la conservation de la faune (Lois du Québec 1969.chapitre 58) stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements pour établir des réserves de chasse et de pêche et y prohiber complète- lr-34 Order in Council Executive Council Chamber Number 8 Québec.January 7, 1972 Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the Kipawa Reserve.Whereas paragraph r of section 77 of the Wild-life Conservation Act (1969.chapter 58) stipulates that the Lieutenant-Governor in Council may make regulations to establish fish and game reserves and totally or partially prohibit hunting and the carrying of arms therein 254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15janvier 1972.104e année, n'2 ment ou partiellement la chasse ainsi que le port d'armes et déterminer les conditions auxquelles la chasse est permise dans ces réserves: Attendu Qu'il est opportun de diminuer la superficie de la réserve, à cause des baux de villégiature qui existent au Nord du lac Decellcs.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minjstre du Tourisme, de la Chasse et de la Pèche: Que la réserve de Kipawa est maintenant décrite comme suit: Un territoire d'une superficie d'environ 1.790 milles carrés faisant partie du comté de Témiscamingue.et dont le périmètre peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne separative des cantons Guy et Halles avec l'emprise sud du chemin qui va du lac Simard à la rivière de l'Êpinetle; de la.dans une direction générale Est.suivant ladite emprise dudil chemin jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest du part de La Vérendrye; de là.dans une direction générale Sud suivant la limite ouest du parc de La Vérendrye.soit une distance approximative de 66 milles, la limite sud du parc de La Vérendrye.jusqu'à la rive est de la baie de l'Orignal du lac Dumoine, d'une distance approximative de 5.8 milles; de là, en direction générale Sud suivant les rives est et sud du lac Dumoine.jusqu'au dépôt « Dumoine »; de là Sud 88° Ouest, 3.5 milles; de là.Nord 66° 30' Ouest, jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des cantons Dièreville et la Chaudière, soil une distance approximative de 8.5 milles; de là, en direction franc sud longeant la ligne separative des cantons La Chaudière et Calcar des cantons Dièreville et Giroux.contournant le lac qui s'y rencontre par la rive est, jusqu'au petit lac.soit une distance approximative de 7.1 milles: de là.Nord 55° 30' Ouest jusqu'à sa rencontre avec la rivière Pin-Blanc, sur une distance approximative de 5.4 milles en contournant la rive nord du premier lac qui s'y rencontre et la rive sud du deuxième: de là.Sud 63° 30' Ouest jusqu'au lac Poubert.d'une distance approximative de 3.8 milles; de là, Sud 86° 30' Ouest jusqu'au lac Clair, d'une distance approximative de 2.9 milles; de là.contournant ledit lac par la rive nord jusqu'à son extrémité ouest; de là.Sud 61° Ouest, jusqu'à la rivière Desjardins sur une distance approximative de 2 milles: de là.la rive sud du lac Sairs.la rive sud de la rivière Kipawa jusqu'au portage (ragged chulc); de là, traversant ladite rivière jusqu'à sa rive nord; de là, les rives nord et nord-est des rivières Kipawa et Birch Creek, jusqu'au lac McKillop; de là Nord 50° Ouest, 2 milles: de là.Nord 18° 30' Ouest.5.3 milles; de là.Sud 65° Ouest.2.5 milles; de là.Nord 17° Ouest, 2 milles; de là.Nord 82° Ouest, 2.5 milles; de là.Nord 4° 30' Ouest.2.5 milles; de là, Nord 30° Est, jusqu'à la décharge du petit lac Bouleau d'une distance approximative de 2.3 milles; de là.Nord 73° Ouest, jusqu'à l'extrémité sud-est du lac Ostaboningue d'une distance approximative de 2.25 milles; de là, longeant les rives sud et ouest du lac and determine the conditions upon which hunting is permitted in such reserves; Whereas it is expedient to reduce the area of the reserve by reason of resort leases existing to the north of Dccelles lake.It is ordered accordingly, upon the recommendation oflhe Minister of Tourism.Fish and Game: That the Kipawa Reserve be now described as follows: A territory of an area of some 1.790 square miles being part of the county of Témiscamingue and the perimeter of which may be described as follows: Starting at a point situated al the intersection of the dividing line between the townships of Guy and Halles and the south line of the right of way of the road from Simard lake to de l'Epinetle river; thence in a generally easterly direction, along the said line of the right of way of the road to its intersection with the west limit of La Vérendrye park; thence in the generally southerly direction along the west limit of La Vérendrye park, a distance of some 66 miles, the south limit of La Vérendrye park of the east shore of the l'Orignal bay on Dumoine lake, a distance of some 5.8 miles; thence in a generally southerly direction along the east and south shores of Dumoine lake, to Dumoine depot: thence south 88° west.3.5 miles; thence north 55°30' west to tis intersection with the dividing line between the townships of Dièreville and la Chaudière, a distance of some 8.5 miles: thence in a due southerly direction along the dividing line between the townships of la Chaudière and Calcar and the Townships of Dièrelle and Giroux around the lake on such line on the east shore, to a small lake, a distance of some 7.1 miles; thence north 55*31' west to its intersection-with Pin-Blanc river, a distance of some 5.4 miles around the north shore of the first lake on the line and the south shore of the second; thence south 63°30' west to Poubert lake, a distance of some 3.8 miles; thence south 86°30' west to Clair lake, a distance of some 2.9 miles; thence around the said lake on its north shore to its west end; thence south 61° west to Desjardins river, a distance of some 2 miles; thence the south shore of Sairs lake, the south bank of Kipawa river to \"ragged chute\" portage; thence across the said river to its north bank; thence the north and northeast banks of Kipawa and Birch Creek rivers, to McKillop lake; thence north 50° west, 2 miles; thence north 18°30' west, 5.3 miles; thence north 65° west, 2.5 miles; thence north 30° east, to the outlet of the smaller Bouleau lake, a distance of some 2.3 miles; thence north 73° west to the southeast end of Ostaboningue lake, to its north end; thence north 70° east to the dividing line between the townships of Blondeau and Guillet around the south shore of the lakes laying on such line, a distance of some 10.7 miles; thence north 56°30' east to Soufflot lake around the south shore of the lakes kying on such line, lr\u2014yi QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 15.1972.Vol.104.No.2 Ostaboningue jusqu'à son extrémité nord; de là, Nord 70° Est.jusqu'à la ligne separative des cantons Blondeau et Guillet, en contournant la rive sud des lacs qui s'y rencontrent, soit une distance approximative de 10.7 milles; de là, Nord 56° 30' Est, jusqu'au lac Soufflot, en contournant la rive sud des lacs qui s'y rencontrent, soit une distance approximative de 9.8 milles; la rive ouest du lac Soufflot, la rive ouest de la rivière Marécageuse, les rives ouest et nord du lac des Fourches jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des cantons Delbreuil et Halles; de là, vers l'Est, cette dite ligne separative ainsi que la ligne separative des cantons Guy et Halles jusqu'au point de départ.Que l'arrêté en conseil numéro 4145 du 11 novembre 1970, concernant la réserve de Kipawa, soit abrogé; Que publication soit faite dans la Gazelle officielle du Québec.Le Greffier du Conseil exécutif Julien Chouinard.44017-o 255 a distance of some 9.8 miles; the west shore of Soufflot lake, the west bank of Marécageuse river, the west and north shores of des Fourches lake of its intersection with the dividing line between the townships of Delbreuil and Halles; thence easterly such dividing line between the townships of Guy and Halles to the starting point.That Order in Council number 4145, dated ii November 1970, respecting the Kipawa Reserve, be repealed.That publication be made in the Québec Official Gazelle.Julien Chouinard, Clerk of the Executive Council.44017-o Avis de modification Notice of amendment Imprimerie \u2014 Région de Montréal Le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre, l'honorable Jean Cournoyer, donne avis par les présentes, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi des décrets de convention collective (S.R.Q.1964, chapitre 143 et modifications), qu'il désire consulter les parties contractantes au décret numéro 2114 du 4 novembre 1964 et modifications, relatif à l'industrie et aux métiers de l'imprimerie dans la région de Montréal, et toute autre partie intéressée, au sujet d'une modification au champ d'application professionnel dudit décret, dont le texte est mentionné ci-après, avant de soumettre telle modification à l'appréciation et à la décision du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.La nouvelle exemption suivante sera ajoutée au paragraphe 2° de l'article 1 dudit décret: « *) Les salariés d'un atelier dont les activités principales ne sont pas des travaux d'impression, de composition, de réglage ou de reliure de livres ou de volumes.» La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un arrêté en conseil peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans amendement.L'arrêté en conseil ne peut entrer en vigueur avanl la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis dans la Gazelle officielle du Québec.Printing Industry \u2014 Montréal Region Pursuant to the provisions of Section 8 of the Collective Agreement Decrees Act (R.S.Q.1964, chapter 143 and amendments), the Honourable Jean Cournoyer, Minister of Labour and Manpower, hereby gives notice that he wishes to consult the contracting parties to Decree No.2114 of November 4, 1964 and amendments, respecting the Printing Industry and Trades in the Montréal Region, and any other interested party, concerning an amendment to the professional jurisdiction of the said decree, hereinafter mentioned, before submitting such amendment to the Lieutenant-Governor in Council for his consideration and decision.The following new exemption will be added to subsection 2 of Section I of the said decree: \"(k) The employees of a plant whose main business operations are not printing, composing, ruling or the binding of books or volumes.\" Publication of this notice does not make binding the provisions therein.Such provisions, with or without amendments, can be made binding only by an order in council that cannot come into force before the date of its publication in the Québec Official Gazelle.During the thirty days following publication of this notice in the Québec Official Gazelle, the Honourable lr-.w 256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1972.104e année, n\" 2 l'honorable.ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-minislre.RÉAL MlREAULT.44012-0 Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre.Québec, le ISjanvier 1972.Minister of Labour and Manpower will consider objections which interested parties may wish to make.REAL MlREAULT, Deputy Minister.44012-o Department of Labour and Manpower, Québec, January 15, 1972.Ministère de l'Assemblée nationale Department of National Assembly Avis Avis public est par les présentes donné que les projets de loi suivants ont été référés, après la Ire lecture, pour étude à la Commission parlementaire spéciale des corporations professionnelles: Bill 264 \u2014 Loi des comptables agréés; Bill 266 \u2014 Loi sur la denturologie.Les personnes intéressées ont un délai de trente (30) jours, à compter de la présente publication, pour déposer au Secrétariat des commissions cent (100) exemplaires de leur mémoire, accompagnés de deux cents (200) exemplaires d'un bref résumé.Le secrétaire des commissions parlementaires, 4401 l-o Jacques Pouliot.Notice Public notice is hereby given that the following bills have been referred, after 1st reading, to the Special Parliamentary Committee on Professional Corpora-lions, for examination: Bill 264 \u2014 Chartered Accountants Act; Bill 266 \u2014 Denturologists Act.Interested persons are granted a delay of thirty (30) days from ihe date of this notice, to deposit al the Secretariat of Committees, one hundred (100) copies of their briefs, together with two hundred (200) copies of a short summary thereof.Jacques Pouliot, 44011 -o Secretary of Parliamentary Committees.Avis Avis public est par les présentes donné que.dans le cas spécifique de la commission parlementaire spéciale sur les Corporations professionnelles chargée d'étudier le projet de loi numéro 250 et les projets de loi qui lui sont connexes, le délai de trente (30)jours prévu dans les règles de pratique concernant les commissions parlementaires, adoptées par l'Assemblée nationale le 19 novembre 1971, commencera à courir à compter de la date du présent avis.Le secrétaire associé des commissions parlementaires.4401 l-o Denis Pérusse.Notice Public notice is hereby given that solely as regards the Special Parliamentary Committee on Professional Corporations entrusted with the examination of Bill 250 and the bills related thereto, the thirty (30) day delay provided for in the rules of procedure respecting Parliamentary Committees, adopted by Ihe National Assembly on November 19th, 1971.shall commence on the date of this notice.Denis Pérusse.Associate Secretary of Parliamentary Committees.4401 l-o Avis Avis public est par les présentes donné que les sujets suivants concernanl la réforme électorale ont été référés, pour étude, à la Commission de l'Assemblée Nationale.1° La loi électorale a) Liste permanente: enumeration et révision; b) Mécanismes d'identification; c) Mécanismes de scrutin; Notice Public notice is hereby given that the following items, respecting electoral reform, have been referred for study to the Committee of the National Assembly: I, Election Act fl) Permanent list: enumeration and revision; b) Means of identification; c) Modes of polling; ik\u2014J* QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.January 15.1972.Vol.104.No.2 d) Dépenses électorales: e) Publicité et sondages électoraux; f) Autres sujets.2° Le financement des partis 3° La loi de la contestation des élections.Les personnes intéressées ont jusqu'au 15 février 1972 pour déposer au bureau du Secrétaire de la Commission de l'Assemblée Nationale, vingt-cinq (25) exemplaires de leurs mémoires, accompagnés de vingt-cinq (25) exemplaires d'un bref résumé.Le Secrétaire de la Commission de l'Assemblée Nationale.Raymond Desmeules.Ch.131 Édifice « A » Hôtel du Gouvernement Québec P.Q.4401 l-o d) Election expenses; e) Election publicity and public-opinion poils; f) Other items.2.Financing of parties 3.Provincial controverted elections act.Interested persons have until the 15th of February 1972 to deposit at the office of the Secretary of the Committee on the National Assembly twenty-five (25) copies of their briefs together with twenty-five (25) copies of a summary thereof.Raymond Desmeules, Secretary of ihe Committee on ihe National Assembly.Room 131 Building \"A\" Parliamenl Buildings Quebec 4401 l-o lr\u201440 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.January 15, 1972, Vol.104, No.2 259 INDEX No 2 Partie II: lois et règlements \u2014 Part II: Laws and Regulations ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS IN COUNCIL 4333 \u2014 ( 1971) Signature de certains documents du ministère des Affaires sociales, règlement.249 4333 \u2014 (1971) Signing of certain documents of the Social Affairs Department, regulation.249 4344 \u2014 (1971) Régie des Loteries et Courses en matière de systèmes de loteries et les modalités selon lesquelles des licences peuvent être délivrées, pouvoirs de la régie.249 4344 \u2014 (1971) Régie des Loteries et Courses as regards lottery schemes anil the terms and condition for .the issue of licences, powers of Ihe Régie.249 4371 \u2014 (1971) Transfert de fonctionnaires du ministère des finances à l'Office de planification et de développement du Québec.4371 \u2014 (1971) Transfer of officers of the Finance Department to the Québec Planning and Development Bureau.4419\u2014 (1971) Soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans le Territoire de la Région de la Baie .lames.4419 \u2014 Withdrawal from staking of certain land in the Territory of the .lames Bay region.7 \u2014 Boeuf musqué.7 \u2014 Musk-oxen.8 \u2014 Réserve de Kipawa.254 8 \u2014 Reserve of Kipawa.254 250 250 251 251 254 254 DEPARTMENTS National Assembly for study Hems referred to Ihe Committee of the National Assembly Contestation des élections, Loi de la.257 Controverted Elections Act.257 Election Act.257 Electorale.Loi.257 Financement des partis.257 Financing of Parties.257 MINISTERES Assemblée nationale pour élude Sujets référés à la Commission de l'Assemblée Nationale Commission parlementaire spécial Chartered Accountants Act (Bill 264) Comptables agréés, loi des (Bill 264).Denturologie, Loi sur la (Bill 266).Denturologists Act (Bill 266).Code des professions (Bill 250) (délai) Professional Code (Bill 250) (Delay).Committee Special Parliamentary 257 257 257 257 257 257 Travail et de la Main-d'oeuvre Labour and Manpower Imprimerie.Région de Montréal (Mod.).256 Printing, Montreal Region (Ameiut.).256 SOMMAIRE SUMMARY Avis juridiques.P»ge 246 Judicial Notices.P*fc* 246 Lois et règlements.page 259 Laws and Regulations.page 259 Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec 4, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec 4, P.Q. Nouvelle classification des avis: Partie I: Avis juridiques Partie II: Lois et règlements "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.