Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 avril 1973, Partie 1 samedi 7 (no 14)
[" 4.GAZETTE QUEBEC g 4 OFFICIELLE OFFICIAL -DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1981 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the (leadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÊ, Québec Official Publisher 1982 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: 81 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1) : du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion : 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1) : from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, , Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1983 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Ministère des Institutions Department of Financial financières, compagnies Institutions, Companies et coopératives and Cooperatives Lettres patentes (Ire partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres to Part I of the Companies Act, he has granted letters patentes constituant en corporation: patent incorporating: Nom / Name A.B.C.Cement Inc.Ciment A.B.C.inc.Admiral Securities Limited Les Valeurs Mobilières Amiral limitée.Agence de Gestion en Techniques de l'Eau (A.G.T.E.) ltée.Ameublement Tropicana ltée.Tropicana Furniture Ltd.Ardecom inc.Aubec Corporation.Corporation Aubec.Les Autobus Brisebois (1973) ltée.Brisebois Bus Lines {1978) Ltd.Les Autobus Roland inc.Automobile Renault (St-Laurent) ltée.Renault Automobile (St.Laurent) Ltd.Aviation Planning International Ltd.Planification Internationale en Aviation ltée.B & 0 Plastic Industries Ltd.Les Industries du Plastique B & O ltée.Bamo inc.Baron & Fils inc.Bar-Salon Le Sorcier inc.Bayer Electric Inc.Les Entreprises Electriques Bayer inc.Berry fast Products Limited.Les Produits Berryfast limitée.Bijouterie André Marchand inc.Incorporation Siège social / Head Office Date Montée du Moulin, Mont-Laurier.05 02 73 55 d'Auteuil Street, Québec.02 02 73 Longueuil.16 03 72 4248 Bélanger Street East, Montréal 408 07 03 73 1530, rue du Collège, Saint-Laurent____ 16 02 73 Montreal.08 03 73 Pointe-Claire.12 03 73 Saint-Jérôme.12 03 73 6875 Côte de Liesse Road, Saint-Laurent 22 12 72 800 Dorchester Boulevard West, Montreal.23 02 73 Montreal.26 02 73 Longueuil.02 02 73 1808, avenue Poulin, Québec 5.26 02 73 Montréal.22 12 72 471 Eveline Street, Laval.16 02 73 6540 Park Avenue, Montreal.14 02 73 3759, boulevard Lévesque, Laval.05 03 73 1984 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.10b, No.U Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date Bijouterie B.Scrko inc.Bijouterie Lucien Larose inc.Borg-Warner Credit Canada, Ltd.Crédit Borg-Warner Canada, ltée.Bourcier Industries Inc.Industries Bourcier inc.G.Bourque & Associés inc.Bourque & Bouchard Metal Inc.Métal Bourque & Bouchard inc.Boutique de Chaussures La Belle inc.Boutique Famor inc.Boutique La Godasse inc.Boutique Roane inc.Roland Brassard inc.Brasserie des Remparts inc.Rampart Brewery Inc.Brasserie Le Caucus inc.Brolek Corporation.C.A.Graphics Inc.Les Graphiques C.A.inc.Calendar Investment Company Limited.Société d'Investissements Calendrier limitée.Canadian European Pastry Inc.La Pâtisserie Canadienne Européenne inc.Cannonball Truck Rentals & Leasing (Québec) Ltd.Locations de Camions Cannonball (Québec) ltée.Cape Cod Fish & Lobster House Inc.La Maison du Poisson & Homard Cape Cod inc.Capri Copy Service Inc.Service de Copie Capri inc.Léo Cauchon Construction Inc.Construction Léo Cauchon inc.Centre d'Accueil Marie-Rivier inc.Centre d'Éducation Canine CD.inc.Centre de Plein Air aux Petits Mats inc.Centre de Rénovation Cascade inc.Cascade Renovation Center Inc.Centre du Pneu Upton inc.Upton Tire Centre Inc.3611 St.Lawrence Boulevard, Montréal.07 03 73 405, boulevard St-Martin, Laval.26 02 73 Montréal.05 02 73 Laval.17 01 73 6351, 9e Avenue, Rosemont.20 01 73 Sainte-Foy.16 02 73 251 Mount Royal Avenue East, Montreal.15 01 73 3681 Ontario Street East, Montreal.01 03 73 6642 St.Hubert Street, Montreal.23 02 73 160, rue Notre-Dame, Repentigny.06 12 72 Jonquière.05 03 73 Québec.01 03 73 Lachute.26 02 73 44, boulevard St-Cyrille est, Québec- 09 03 73 1252 Stanley Street, Montreal.22 02 73 55 d'Autcuil Street, Québec.02 02 73 5205 Sherbrooke Street West, Montreal.13 10 72 Dorval.12 02 73 1838 St.Catherine Street West, Montreal 26 02 73 11275 Côte de Liesse Road, Dorval.06 03 73 Château-Richer.21 02 73 Saint-David.06 12 72 Montréal.16 01 73 7145, rue Sherbrooke est, app.30, Montréal 427.11 01 73 395 Morning Side, Dollard-des-Ormeaux.12 03 73 Route rurale numéro 1, paroisse d'Upton 05 03 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1978, 105' année, n° 14 1985 Nom / Name Central Vacuum Service Inc.Service Central de Réservoirs inc.Château Mirabelle inc.Chaussures Cléo inc.Chevrolet Duval inc.Duval Chevrolet Inc.Clinique La Renaissance inc.Club de Chasse et Pêche Sisco inc.Club de Placement Cercle inc.Club de Vacances Ecovac inc.Ecovac Holiday Club Inc.Coffrage Filceau inc.Filceau Form Inc.Les Coffrages Gebel inc.Gebel Frame-Work Inc.La Compagnie de Tuiles du Québec inc.La Compagnie Diversifiée Edelstein ltée.Edelstein Diversified Co.Ltd.La Compagnie Villa du Saguenay-Lac-St-Jean inc.Conseiller en Personnel Joliette inc.Conseiller & Services Techniques Biron inc.Construction André Caron inc.André Caron Construction Inc.Construction Boritel ltée.Boritel Construction Ltd.Construction Boulogne inc.Construction Gilbert Boucher inc.Construction H.G.C.ltée.H.G.C.Construction Ltd.Construction Renaud et Roy inc.Les Constructions C.L.R.Marcoux inc.Constructions Claude Clément & Fils ltée.Constructions J.L.R.ltée.La Corporation d'Administration d'Immeuble Mancor limitée.Mancor Property Management Corporation Limited.Crédit Bombardier ltée.Bombardier Credit Ltd.D.& D.Carrière ltée.Incorporation Siège social / Head Office Date Pointe-aux-Trembles.27 02 73 Sainte-Scholastique.13 03 73 6830, rue St-Hubert, Montréal.17 01 73 Longueuil.15 02 73 Montréal.02 03 73 325, boulevard St-Joseph, Hull.05 02 73 85, rue Ste-Annc, Rivière-du-Lcup.23 02 73 1117 St.Catherine Street, Montreal____ 08 02 73 8280, boulevard Lévesque, Laval.13 02 73 Montréal.20 01 73 191, rue St-Louis, Pointe-Gatineau.11 12 72 225 Sheraton Drive, Montreal West____ 08 03 73 Chicoutimi.26 02 73 75, rue St-Pierre nord, Joliette.22 12 72 1453, Roosevelt, Saint-Hubert.23 02 73 Shawinigan-Sud.15 02 73 Bécancour.01 02 73 4200, 4e Avenue, Québec.11 12 72 1330, boulevard Forest, app.401, Val d'Or.06 03 73 Pointe-Gatineau.22 12 72 Saint-Eustache.21 02 73 Sainte-Marie-de-Beauce.28 12 72 526, rue Bélanger, Buckingham.07 12 72 Saint-Georges.05 03 73 1403, du Collège, Saint-Laurent.16 01 73 Valcourt.20 03 73 Lachute.02 03 73 1986 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Nom / Name Gerald Daneau inc.Darius Gold Mines Inc.Les Mines d'Or Darius inc.David-Allan Wallpaper and Draperies Co.Ltd.Compagnie de Tapisserie et de Draperie David-Allan ltée.De Gaspê Parking Inc.Stationnement de Gaspé inc.Dionysios Enterprises Inc.Les Entreprises Dionysios inc.Disques P.A.X.inc.Les Distributions D.Q.B.inc.D.Q.B.Distributio7i Inc.Les Distributions Juvenia inc.P & E Distributors Inc.Les Distributeurs P & E inc.Domaine Joie de Vivre inc.Dombek inc.Armand Dumont inc.Dynam inc.Les Écuries Brun & Or inc.Brown & Gold Stables hic.Les Éditions du Haut-Yamaska inc.Élan Sales Corp.Corporation de Ventes Élan.Elhara Management Corporation.La Corporation de Gestion Elhara.Empire Slacks Ltd.Les Pantalons Empire ltée.Enlèvement de Rebus St-Laurent inc.St-Laurent Carbage Removal Inc.Les Entreprises Alcide Cousineau inc.Les Entreprises Arthur Nadeau inc.Les Entreprises Carget inc.Les Entreprises de Construction Toupin inc.Les Entreprises L.L.Po-Mer inc.Les Entreprises Lalancette & Fils ltée.Les Entreprises Shervillc inc.Incorporation Siège social / Head Office Date 760, rue Papineau, McMasterville.15 03 73 55 d'Auteuil Street, Québec.05 03 73 4056 Jean Talon Street West, Montreal.13 02 73 160 St.Viateur Street East, Montreal.09 02 73 210 St.Luc Boulevard, Asbestos.27 12 72 189, Rockland, Mont Royal.02 02 73 Montréal.12 03 73 Montréal.06 02 73 Chambly.06 02 73 Saint-Eustache.05 03 73 Laval.26 01 73 Sept-îles.18 12 72 Centre d'Achats Bourg-Royal, Charles-bourg.16 03 73 8747, Saguenay, Lasalle.02 03 73 33, Lansdowne, Granby.02 10 72 5605 de Gaspé Street, Montreal.22 02 73 62 Summit Crescent, Montreal.05 03 73 5455, de Gaspé, Montréal.13 03 73 Montréal.12 01 73 393, rue Guilbault, Longueuil.13 03 73 1035, avenue Myrand, Sainte-Foy.21 11 72 7490, 19e Avenue, Montréal.28 02 73 6645, rue Molson, Montréal.12 03 73 Saint-Roch-de-l'Achigan.27 02 73 189, rue Principale, Girardville.13 02 73 Sherbrooke.09 02 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1987 Nom / Name Équipement Électronique Côte Nord inc.Les Équipements Carebo inc.Est Service Québec inc.Estrie Toyota inc.Excavation Mirabel ltée.Excavations Vidolo limitée.Vidolo Excavation Limited.Fashion Mart Restaurant Limited.Restaurant Mode Mart limitée.Les Fenêtres de l'Est Victoriaville inc.Ferme Gravel ltée.La Ferme Z.Dagenais inc.Flex Investments Ltd.Les Placements Flex ltée.Les Florathèques André Rancourt inc.A.Frechette & Associates Ltd.A.Frechette & Associés ltée.Réal Gagné Construction Inc.Construction Réal Gagné inc.Les Galeries Lessard Cap Rouge inc.Leslie A.Gallagher ltée.Garage Diapolo inc.Alcide Gendron inc.Bert Gendron & Associés inc.Gerbcco inc.Gilnix inc.Gravure Choquet inc.Choquet Engraving Inc.Groupement Forestier et Agricole de Beauce Sud inc.Guy & Carol Construction Inc.Construction Guy & Carol inc.II.L.B.Investments Ltd.Placements II.L.B.ltée.Hôtel Briand inc.Ideal Crane Service Inc.Service de Grue Idéal inc.Immeubles Bourgeois-Hébert inc.Incorporation Siège social / Head Office Date 2GC3, rue Piuze, Hautcrive.18 01 73 BaieComeau.08 03 73 Sherbrooke.09 02 73 6, chemin Irwin, G ran by.22 02 73 Saintc-Marthe-sur-le-Lac.02 02 73 2122, rue Régent, Montréal.08 02 73 225 Chavanel West, Montreal.23 02 73 Victoriaville.15 03 73 208, Pied de la Côte, Maskinongé.07 03 73 Shawbridge.02 02 73 Montreal.27 02 73 5558, Jean Talon est, Montreal.31 01 73 215 Dubé Street, Chftteauguay-Centre.16 01 73 309 Boucher, Matane.01 02 73 Cap-Rouge.26 02 73 86 Grove, Granby.12 03 73 Saint-Jacques-de-Leeds.03 01 73 La Providence.29 01 73 5, Aima, Place Bonavcnturc, Montréal.02 02 73 524, Jean Talon ouest, Montréal.18 01 73 6031, rue Chateaubriand, Montréal 326.15 02 73 Montréal.14 02 73 Saint-Martin, cté Beauce.28 02 73 Scpt-Iles.02 03 73 415 St.James Street West, Montreal.12 03 73 Sept-îles.18 12 72 1074, rue Bcllevue, Greenfield Park- 07 03 73 Kénogami.16 03 73 1988 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Nom / Name Les Immeubles Home Smith (Sherbrooke) limitée.Home Smith Properties (Sherbrooke) Limited.Les Immeubles J.M.Boily inc.Les Immeubles Payette & l'Heureux inc.Les Industries G.Grolcau inc.G.Groleau Industries Inc.L'Institut de Recherches pour l'Éducation du Futur du Québec inc.Investissements J.M.L.inc.Isabelle Shops Ltd.Les Maisons de Commerce Isabelle ltée.Isram Holding Co.Inc.Compagnie de Portefeuille Isram inc.J.& B.Furniture Transport Québec Inc.Transport d'Ameublement J.& B.Québec inc.Les Jardins Pondev ltée.Pondev Gardens Ltd.Jenkins & Arsenault Realties Inc.Immeubles Jenkins & Arsenault inc.John Fix Agency Ltd.L'Agence John Fix ltée.Laboratoire d'Optique Éclair inc.Laboratoires Prop ltée.Prop Laboratories Ltd.Lamothe Tire Casing Ine.Pneus Lamothe inc.Landmark Properties Ltd.Les Immeubles Landmark ltée.Roger Larose inc.Leader Construction (Québec) Ltd.Les Constructions Leader (Québec) ltée.Leclerc Electric hic.Les Installations Électriques Leclerc inc.Litek inc.Luto inc.M.G.Larochelle Construction Inc.Construction M.G.Larochelle inc.Maçonnerie Longueuil inc.Magasin Continental (Bathurst) ltée.Continental Store (Bathurst) Ltd.Incorporation Siège social / Head Office Date Montréal.01 03 73 Route Régionale, CP.52, Chambord.15 02 73 Forestville.26 02 73 8, rue Charron, app.1, Lemoyne.05 02 73 Montréal.11 12 72 Mont-Royal.26 02 73 4419 St.Lawrence Boulevard, Montreal.27 12 72 Montréal.08 03 73 Montreal.23 01 73 Montréal.08 03 73 1074, rue Bellevue, Greenfield Park.07 03 73 3034 Marcel Street, Saint-Laurent 382.05 03 73 Montréal.24 01 73 675, boulevard Henri-Bourassa est, Mont- 12 03 73 réal.Saint-Louis-de-Terrebonne.08 02 73 Montréal.08 02 73 1490, rue Fleury, Montréal.09 03 73 Hull.01 03 73 Granby.05 12 72 Longueuil.12 03 73 Québec.05 03 73 164, rue Cousineau, Laval.16 02 73 2080, rue Marquette, Longueuil.08 03 73 Chicoutimi.14 02 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" 1A 19S9 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date M agister Mining Corporation Limited.55 d'Auteuil Street, Québec.02 02 73 Société Minière Magister limitée.Mai Tai Restaurant Inc.Longueuil.05 03 73 Restaurant Mai Tai inc.Victor Mailloux inc.5727, 4c Avenue, Roscmont.26 02 73 Maison Funéraire Trudel inc.400, rue Labellc, Saint-Jérôme.12 01 73 Maisons Mobiles Waterloo inc.132, rue Allen, Waterloo.16 03 73 Les Maisons Qucbco inc.Val d'Or.16 02 73 Quebco Houses Inc.Les Maisons R.Julien inc.Val d'Or.09 03 73 Marché Alphonse Ouellct inc.Rivière-du-I.oup.27 02 73 Marojo Sales Inc.3355 Queen Mary Road, Montreal.22 02 73 Les Ventes Marojo inc.Mélange d'Encre Colobcc inc.Montréal.19 02 73 Colobec Matching Ink Inc.Mertl & Dain Limited.336 Taché Boulevard, Hull.22 02 73 Mertl & Dain limitée.Michaud & Larue inc.282, boulevard St-Jacqucs, Neufclialel.14 03 73 Mirposinc.3859, boulevard Décarie, Montréal.07 02 73 Musanliqua Distribution Inc.848, 1ère Rue, Richelieu.29 01 73 Distribution Musantiqua inc.Nettoyage au Jet de Sable Jett-R inc.8000, 4e Avenue, Anjou.25 01 73 Jett-R Sandblasting Inc.Nobel Construction inc.-.1000, rue Lawlor, suite 202, Saint-Lau- 16 03 73 Construction Nobel inc.rent.Opsisinc.Montréal.13 02 73 Les Papeteries P.M.inc.7410, 19e Avenue, Saint-Michel.19 02 73 Parc d'Amusement de l'Estrie inc.3535, Papineau, suite 1706, Montréal.18 01 73 Maurice Pash Limited.6 Amos, Mart A.Place Bonaventurc, 20 02 73 Maurice Pash limitée.Montreal.Perforatec inc.1500, rue Stanley, Montréal.08 03 73 Ferma Sprinklers Inc.840 Décaric Boulevard, Montreal.05 03 73 Appareils d'Arrosage Perma inc.Photocopie F.B.E.inc.Montréal.20 12 72 Photographie P.D.C.inc.Sainte-Foy.13 03 73 Place Deschênes Limited.131 Richer Street, Hull.17 01 73 Place Deschênes limitée.Les Placements du Havre liée.1026, rue St-Jean, Québec.05 02 73 Les Placements Jeton Bleu inc.1303 Greene Avenue, Wcstmount.20 02 73 1990 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1978, Vol.105, No.U Nom / Name Les Placements Le Barrage inc.Les Placements Le Filtre inc.Plomberie Beauport inc.Les Productions Michel Des Rochers inc.Produits de Caoutchouc M.B.inc.Programmation M.G.N, inc.M.G.N.Programming Inc.Promotions Propop inc.Provincial Livestock Exporters Co.Ltd.La Cie des Exportateurs de Bétail Provincial ltée.Provincial Veal Co.Ltd.La Cie Provinciale de Veau ltée Québec Sauna hic.Sauna Québec inc.Rennex Canada ltée.Rennex Canada Ltd.Restaurant Les Chenets inc.Restaurant Perfecta de Joliette inc.Les Restaurants Marie-Victorin inc.Revue Nature inc.Rexway Sheet Metal (Québec) Limited.Feuille Métallique Rexway (Québec) limitée.Harold C.Rosen inc.J.Emile Roy & Fils inc.Ste-Claire Abattoir Ltd.Abattoir Ste-Claire ltée.Salaison Valleyfield inc.Sécurité Lenet ltée.Sedif inc.Service de Vente Moderne inc.Services Forestiers Spécialisés S.F.S.ltée.S.F.S.Specialized Forest Services Ltd.Nat Siegler inc.Sing Along Sam Pizza Inc.Pizza Sam Chantons en Choeur inc.Société d'Aqueduc d'Allen's Mill ltée.Société de Promotions V.T.T.inc.La Société Philuc inc.Incorporation Siège social / Head Office Date Victoriaville.09 03 73 Victoriaville.14 03 73 454, rue Seigneuriale, Beauport.14 03 73 1102, rue Louvain est, Montréal.01 03 73 Sherbrooke.09 02 73 Cap Santé, cté Portneuf.15 01 73 Place Alexis Nihon, Montréal.21 02 73 385 Bernard Street, apt.3, Beloeil.05 02 73 385 Bernard Street, Apt.3, Beloeil.06 02 73 6070, Parent, Brossard.17 01 73 10049, rue London, Montréal-Nord.08 03 73 Montréal.15 02 73 Joliette.09 03 73 Sainte-Gertrude, Bécancour.06 03 73 3645, boulevard St-Joseph est, Montréal.07 02 73 15 Papineau Street, Hull.17 01 73 1449 St.Alexander Street, Montreal____ 27 02 73 265, rue Vitré ouest, Montréal.26 02 73 Route rurale numéro 1, La Plaine.24 01 73 147, rue Salaberry, Valleyfield.06 02 73 2556, Dalton, Sainte-Foy.14 12 72 l'Islc-Verte, Rivière-du-I.oup.19 03 73 115, Place Jouvence, Sainte-Foy.14 02 73 Grand'Mère.18 12 72 5575 Randall, Côte St.Luc.12 03 73 6339, rue St-Hubert, chambre 305, Mont- 21 02 73 réal.Rang St-Paul, Saint-Léonard.05 03 73 Montréal.13 02 73 Québec.13 12 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1991 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date Grandes-Piles, cté Laviolette.12 03 73 3967, rue St-Denis, Montréal.07 02 73 Montréal.27 12 72 Route 18, Notre-Dame-de-la-Merci.03 01 73 5825 MacDonald Avenue, Montreal____ 28 02 73 1165 Forest Avenue, Laval.12 02 73 Val d'Or.24 01 73 601, rue Flynn, Québec.13 02 73 1 Place Ville Marie, Montreal.19 01 73 Montreal.16 02 73 855, rue Eiffel, Laval.19 01 73 Route rurale numéro 4, Cookshire.06 02 73 148 Brock Avenue North, Montreal West 31 01 73 78 Charles Street West, Longueuil.30 01 73 Montréal.23 02 73 3 Place Ville Marie, Montreal.01 03 73 Station de Ski Vallée Pruneau inc.Stéréo Saint-François inc.Techniques Educatives M.C.R.V.L.inc.A.& P.Therrien inc.Ting-a-Ling Fashions Inc.Les Modes Ting-a-Ling inc.Tortan Products Ltd.Les Produits Tortan ltée.Transport Adrien Champagne & Fils inc.Transport Paul Néron inc.Trebor (North America) Ltd.Trebor (Amérique du Nord) ltée.Albert Trottier Enterprises Inc.Les Entreprises Albert Trottier inc.Les Ventes Abbatiales inc.Abbey Sales Inc.Villeneuve & Choinière inc.W.R.Little Holdings Inc.Les Placements W.R.Little inc.Wong's Star Restaurant Inc.Restaurant Étoile Wong inc.Woodhaven (Québec) ltée.Zizanis Travel Corp._.La Corporation de Voyage Zizanis.Le directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 51176-0 Director of the Companies Service.\t Lettres patentes (3° partie)\tLetters Patent (Part III)\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation :\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t Nom / Name\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date L'Aide à l'Enfance Inadaptée de l'Est de Montréal.The Alexander the Great Brotherhood of Eastern Mace-Fraternité de la Macédonie de l'Est Alexandre le Grand.\t71, rue Champêtre, Montréal-Est.7715 de l'Épée, Apt.6, Montréal\t21 04 70 .26 01 73 1992 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Nom / Name Association des Bienfaiteurs de Ste-Annc de Cantalupo Association des Commerçants Place La Seigneurie inc.L'Association des Marchands de Place Pointe-aux- Tremblcs inc.Place Pointe-aux-Trembles Merchants Association Inc.Association des Orthoptistes du Québec.Association des Trappeurs des Cantons de l'Est inc.Association Québécoise des Artistes de la Danse inc.Les Ateliers du Godendard inc.Blomar inc.Camp Gatineau inc.Centre de Bénévolat de Cowansville.Cowansviïle Volunteer Service Centre.Club Auto-Neige des 47 inc.Le Club de Hockey Les Aigles de St-Bernard inc.Le Club de l'Âge d'Or de Dubuisson.Club de l'Âge d'Or de Ste-Dorothée.Club de l'Âge de St-Félicien.Club de Moto-Neige Hemmingford inc.Henimingford Snow-mobile Club Inc.Le Club de Moto-Neige Les Gais Campagnards de Beauharnois inc.Club de Moto-Neige Mont-Laurier inc.Club de Natation Jonquièrc-Kénogami inc.Club de Ski Mont Citadelle inc.Le Club des Retraités de Price inc.Club Sportif Le Plateau du Parc inc.Club Sportif Les Franc-Nord Macaziens inc.Club Sportif Pocomoco inc.Comité des Loisirs de Montcbello inc.La Corporation de l'Aréna de Cap Chat inc.La Corporation du Musée du Saguenay inc.L'École Secondaire Montaigne inc.La Garderie Hubertuberlu.Incorporation Siège social / Head Office Date 4280, boulevard Métropolitain est, suite 201, Saint-Léonard.22 01 73 280 Fort St-Louis, Boucherville.20 01 73 1400, boulevard St-Jean Baptiste, Pointeaux-Trembles.29 01 73 Sainte-Foy.16 11 72 1091, rue Ste-Thérèsc, Sherbrooke.08 02 73 1159, St-Jean, Québec.01 03 73 358, rue La violette, Saint-Jérôme.22 12 71 Auberge Laurier, Chemin Sainte-Foy, 15 03 73 Québec 10.5S90 Monkland Avenue, Montreal.10 02 72 Cowansville.13 07 72 Sainte-Agathe.29 01 73 Saint-Bernard-de-Dorchestcr.29 01 73 Dubuisson.24 01 73 655, rue Principale, Laval.05 03 73 Saint-Félicien, Lac St-Jean.26 02 73 524, rue Champlain, Hemmingford.13 02 73 Beauharnois.06 02 73 Mont-Laurier.29 01 73 425, rue St-Dominique, Jonquière.12 10 72 Saint-Honoré.07 02 73 Kénogami.20 11 72 Chicoutimi-Nord.09 03 73 Lot 49, Rang B Lac Chaud, La Macaza.18 12 72 Saint-Basile.25 08 72 Montebello.21 02 73 Cap-Chat.12 02 73 Chicoutimi.06 11 72 455, rue Ste-Hélènc, Longueuil.12 02 73 Saint-Hubert.12 01 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1993 Institut de Recherches Didactiques de Laval inc.Ledpo inc.Montreal Health Press.Les Presses de la Santé de Montréal Poltimore Snow Mobile Club.Club de Moto-Neige Poltimore.Salon de la Femme du Québec inc.Service de Loisirs pour Personnes Retraitées de Montréal.Service des Loisirs de la Cathédrale de Montréal.Société des Éditions Populaires de l'Outaouais.Télévision Communautaire La Pocatière inc.422, des Prairies, Laval.19 01 73 17, rue Ste-Thérèse, Lévis.25 10 72 Montreal.16 02 73 Poltimore.05 02 73 279, rue St-Joseph est, Québec.29 12 72 Montréal.01 02 73 Montréal.29 01 73 Casier postal 1014, Hull.09 02 73 La Pocatière.09 01 73 Le directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.51176-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant compagnies il a accordé des lettres patentes supplé- to the Companies Act.lie has granted supplementary mentai res à : le t te rs paten t to : Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes L'Action Sociale, limitée.03 04 Auto Forum inc.15 01 Forum Auto Inc.Best Service People Limited.11 05 Bigras & Vaillancourt inc.11 03 Gilles Blondeau et Compagnie.18 07 Orner Boisvert & Ass.inc.16 11 Boulangerie Blé d'Or inc.30 06 40\t15\t03\t73 73\t05\t03\t73 67\t05\t01\t73 61\t16\t02\t73 69\t14\t02\t73 70\t23\t1)2\t73 7(1\t12\t02\t73 Modifiant le capital / Altering the capital Ancien nom / Former name: Forum Automobiles Inc./ Automobiles Forum inc.Étendant les pouvoirs / Extending the powers Ancien nom / Former name: Jean Vaillancourt inc.1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Modifying certain provisions of letters patent Modifiant le capital / Altering the capital Ancien nom / Former name: Pâtisserie Georges Fortin inc.Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date 1994 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.U Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes Boutique Le Faubourg inc.20 07 71 06 02 73 Murray G.Bulger & Associés (Que- 20 06 69 bec) ltée.29 01 73 Canadian Broadloom (Québec) Ltd.16 02 68 16 11 72 Michel Carrier inc.28 12 71 13 02 73 Club Récréatif des Loisirs Acadiens 23 02 61 20 02 73 de Beauharnois inc.Club Social Colonial inc.17 01 68 07 03 73 Colonial Social Club Inc.Le Collège Français (1965) inc.29 04 65 22 02 73 Collin & Associés inc.28 09 70 09 02 73 Copacabana Café inc.13 07 48 20 02 73 Développement M.L.limitée.26 03 65 09 02 73 M.L.Development Limitea.Domaine.30 08 68 15 02 73 Le Domaine du Verger inc.15 07 70 15 06 72 Dumco Metal Products Co.Ltd.19 02 53 05 03 73 Les Fabricants des Toits de Vinyle 27 08 71 29 01 73 du Québec inc.Gagnon Frères Nouveautés (Port- 31 07 57 29 01 73 Alfred) ltée.Ancien nom / Former name: Les Entreprises Karic inc./ Karic Enterprises Inc.1) Ancien nom / Former name: Dondata inc.2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 1) Ancien nom / Former name: United Carpet Co.Ltd.2) Modifiant les pouvoirs / Altering the powers Ancien nom / Former name: Aqua-Air Techniques inc.Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 1) Diminuant le nombre des adminis- trateurs / Decreasing the number of directors 2) Augmentant la valeur des biens immo- biliers / Increasing the value of immoveable property 3) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 1) Ancien nom / Former name: Léger, Collin & Associés inc.2) Modifiant le capital / Altering the capital Modifiant le capital / Altering the capital Modifiant le capital / Altering the capital 1) Modifiant le capital / Modifying the capital 2) Modifiant lesprivilèges et restrictions/ Modifying the privileges and restrictions Modifiant le capital / Altering the capital Modifiant le capital / Modifying the capital Ancien nom / Former name: Les Entreprises B.B.C.ltée/B.B.C.Enterprises Ltd.Modifiant le capital / Altering Ike capital GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 1995 Nom / Name Les Galeries Mégantic inc.28 06 63 Les Galeries Richelieu inc.22 06 72 The Grand Union Finance Corp.16 02 72 Huron Footwear (1968) Inc.16 10 68 Industrial Fasteners Ltd.04 06 58 Les Industries Chenard inc.26 05 72 Institut Val-du-Lac inc.11 12 59 J.C.N.Wire Industries Ltd.03 03 28 Les Industries du Fil J.C.N, ltée.Jardins Su-Casa inc.13 01 72 Jolen Holdings Ltd.07 02 62 Kwikasair Ltd.29 11 71 Claude Lavigne inc.18 12 72 Lavigueur Auto Inc.14 02 66 Location Finard inc.27 05 63 Pinard Leasing Inc.Miller Holdings Ltd.23 12 32 Morgan Stanley Canada Limited.10 11 71 Morgan Stanley Canada limitée.Pacific Fur & Leather Co.Inc.01 02 63 Compagnie de Fourrure & Cuir Pacifique inc.Modifications Changes 21 07 72 Ancien nom / Former name: Les Entreprises Maron limitée / Maron Enterprises Limited 15 02 73 1) Ancien nom / Former name: Les Investissements Daniel ltée 2) Changeant le siège social / Changing the head office 3) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Modifying certain provisions of letters patent 22 09 72 Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / Modifying certain provisions of letters patent 15 03 73 Modifiant le capital / Altering the capital 16 01 73 Modifiant le capital/ Altering the capital 12 02 73 Ancien nom / Former name: Les Entreprises Chenard inc.01 03 73 Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of immoveable property 08 02 73 Modifiant le capital / Altering the capital 15 12 72 Modifiant le capital / Altering the capital 26 02 73 Modifiant le capital / Altering the capital 13 02 73 Modifiant le capital / Altering the capital 22 02 73 Ancien nom / Former name: Les Agents de réclamations du Golfe inc./ Gulf Claims Adjusters Inc.06 11 72 Modifiant le capital / Altering the capital 12 02 73 Modifiant quelques dispositions des lettres patentes / Correcting some provisions of the letters patent 29 11 72 Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / Modifying certain provisions of letters patent 16 01 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / M edifying provisions of the letters patent 30 12 72 1) Ancien nom / Former name: Pacific Fur Company 2) Modifiant les pouvoirs / Altering the powers Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date 1996 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Nom I Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes Louis Ph.Paquet inc.12 09 61 08 02 73 I,c Pavillon dc Beauharnois inc.29 12 69 16 02 73 Place Montréal inc.02 06 72 14 02 73 Les Productions Roger Garand inc.25 08 58 17 01 73 Lc Rousson inc.25 06 59 13 03 73 La Société Canadienne de Culture 12 06 70 15 02 73 Chinoise de Montréal inc.Canadian Chinese Cultural Society of Montreal Inc.La Société d'Administration Immobi- 26 03 69 12 02 73 Hère Le Gardeur inc.Société Micro-Cinéma ltée.24 07 67 09 02 73 Micro-Cinema Society Ltd.Soucy-Mercury (Ventes & Services) 24 12 65 15 02 73 ltée.Structures Laminex ltée.30 01 53 07 02 73 Laminex Structures Ltd.Tanm International Ltd.29 04 71 04 12 72 Tanni International ltée.Tanzer Industries Ltd.26 10 65 05 12 72 Unity Realty Holdings Limited.27 07 48 12 12 72 Vulcanisation St-Laurent (1970) ltée.23 10 70 28 02 73 Modifiant le capital / Altering Oie capital Modifiant la valeur des biens immobiliers / Modifying the value of immoveable property Ancien nom / Former name: Place Richelieu inc.1) Ancien nom / Former name: Le Théâtre Gamma-Phi inc.2) Étendant les pouvoirs / Extending the powers 1) Ancien nom / Former name: Impala Land Holding Ltd.2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Modifying the provisions of letters paient 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisiotis of the letters patent 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les privilèges et restrictions / Modifying the privileges and restrictions Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers Ancien nom / Former name: Charlebois Automobile ltée / Charlebois Automobile Lid.Ancien nom / Former name: Steel & Timber Structures Ltd.Modifiant le capital / Altering the capital 1) Modifiant le capital / Altering the capi- tal 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Modifying the provisions of the letters patent Modifiant le capital / Modifying the capital Modifiant le capital / Altering the capital Le directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.51176-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105- année, n° U 1997 Avis de correction (I-ettrcs patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters liaient issued to the following companies or corporations: Siège social Incorporation Nom / Name Head office Date\tModifications Corrections Entreprises Salice inc.(Les).11331 Place Salk, 16 11 72 Montréal-Nord\tCorrigeant le capital / Correcting the capital.Ia! directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.51176-o\tPierre D esj a r dins, Director of the Companies Service.Avis d'annulation de lettres patentes Notice of annulment of letters patent (l,r avis) (1st notice)\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis aux compagnies ou Corporations suivantes, constituées par lettres patentes sous l'autorité de la Loi des compagnies: a) qu'elle ont omis de produire le rapport prescrit par l'article 4 de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q.1964, ch.273) pour les années indiquées; b) et qu'en conséquence faute par elles d'avoir fourni ledit rapport pour lesdites années tel que prescrit par la loi et de payer les droits exigibles dans les 60 jours de la publication dudit avis, il entend procéder à l'annulation de la charte desdites compagnies ou corporations.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby notifies the following companies and corporations incorporated by letters patent pursuant to the Companies Act that: (a) they have neglected to file the return required pursuant to section 4 of the Companies Information Act (R.S.Q.1964, Ch.273) for the year(s) indicated below; and that, (b) therefore, should they fail to submit the said return for the abovementioned years, as prescribed by law, and also fail to pay the required fees, within 60 days from the date of publication of this notice, he will annul their charter.Norn / Name Incorporation Date Années des rapports Year(s) for which return required Droits exigibles Exigible fees Borsa Investment Inc.30 03 71 1971 à /to 1972 §20.00 Crémerie Caldcronc inc.04 12 62 1963 à I to 1972 $100.00 Crémerie Stella inc.23 11 62 1963 à/to 1972 $100.00 Deltro Construction Inc.20 04 71 1971 à/to 1972 $20.00 Entreprises Samo inc.12 10 65 1970 à/to 1972 $30.00 Guva Painters Limited.11 03 68 1968 à/to 1972 $50.00 North Landscaping, Inc.19 04 66 1966 à/to 1972 $70.00 Voyageur inc.07 03 61 1968 à/to 1972 $50.00 51176-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.51176-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 1998 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.U Avis dc correction (Lettres patentes supplémentaires) Notice of correction (Supplementary letters patent) I.e ministre îles institutions financières, compagnies The Minister of Financial Institutions, Companies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi «les and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant Compagnies, il a autorisé la correction des lettres pa- to the Companies Act, he has authorized the correction tentes supplémentaires des corporations ou compagnies of the supplementary letters patent issued to the .suivantes: following companies or corporations: Incorporation Nom / Name Date\tL.P.S./ S.L.P.Date\tModifications Changes Just Equipment & Supply Co.(1963) 30 10 63 Limited.\t06 03 73\tRemplaçant la date des lettres patentes supplémentaires / replacing the dale of letters patent supplementary: 29-01-73 par/6î/06-12-72 Le directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.\t51176-0\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.Changement dc nom\tChange of :\tname Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivant:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of:\t Nouveau nom / Neio name Ancien nom / Former name Incorporation Date Celanese Canada Fabrics Limited.Les Tissus Celanese Canada limitée.Centre Commercial Lc Bazar inc.Le Bazar Shopping Center Inc.Entreprises Lac des Maures inc.Matério Goulet inc.Northal Construction Ltd.Construction Northal ltée.Pavillon Mauricien Cap de la Madeleine inc.Pemrep inc.Pinkham & Sons Building Maintenance Inc.Entretien d'Édifice Pinkham & Fils inc.Place Kennedy inc.Marlu Limited.06 02 61 Les Investissements Marcel inc.22 06 72 Gaulh Enterprises (1972) Inc.20 10 72 Entreprises Gauth (1972) inc.Matério inc.18 11 49 Prefabricated Concrete Terra Cotta 09 06 64 Floors and Walls Inc.Le Pavillon du Tennis inc.13 07 55 Insus inc.16 11 72 Pinkham Building Maintenance Inc.02 12 60 Les Placements Mona ltée.06 07 72 Mona Investments Ltd. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° 14 1999 Nouveau nom / New name Ancien nom / Former name Incorporation Dale Pouliot, Guérard & Associés inc.Pouliot, Guérard & Associates Inc.Regional Construction Co.Inc.La Compagnie de Construction Régionale inc.Ruai Ltd.La Société Immobilière du Manoir des Plaines inc., Sybess inc.Lemay, Pouliot, Guérard & Associés inc.14 09 G2 Lemay, Pouliot, Guérard & Associates Inc.Regional Construction Co.09 01 40 Grand Prix Sportswear Inc.06 03 69 Résidence Le Stadacona inc.22 11 72 Taverne Angus inc.21 07 69 Le directeur du service des compagnies, 51176-0 Pierre Desjardins.51176-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de : The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of : Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date Allied Shoe Corp.Association des Pharmaciens Détaillants de la Province de Québec inc.Barry Children's Wear Inc.Berwin Investment Corporation.J.C.Boulet (1970) limitée.Better Brand Ltd.Judy Brand Inc.Burnbrooke Holding Coqwration.Cartier Automobile inc.Chez Francine limitée.La Cie de Gestion P.F.R.inc.Congocan Corporation.Construction Jardin inc.Crescent Finance Corporation.Dorion Construction, limitée.21\t05\t54 08\t09\t51 26\t01\t57 20\t07\t59 07\t12\t70 16\t03\t65 13\t11\t62 28\t04\t64 01\t02\t65 18\t01\t67 12\t06\t68 08\t04\t70 15\t10\t65 09\t03\t33 22\t09\t4S 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 30\t03\t73 2000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date Échos-Vedettes inc.\t11\t03\t69\t30\t03\t73 \t05\t03\t65\t30\t03\t73 \t05\t06\t67\t30\t03\t73 \t03\t10\t59\t30\t03\t73 Gainor Investment Corporation.\t21\t12\t60\t30\t03\t73 Gemlile Ltd.\t08\t05\t63\t30\t03\t73 Glyp Inc.\t18\t10\t61\t30\t03\t73 Roger Pier Imports Ltd.\t17\t07\t68\t30\t03\t73 International Dealers & Converters Inc.\t17\t02\t55\t30\t03\t73 Kosmos Land Corp.\t04\t11\t65\t30\t03\t73 Kres-Kno (Montréal) Ltd.\t22\t03\t60\t30\t03\t73 Laboratoires Allemands Réunis Canada inc.\t17\t07\t61\t30\t03\t73 \t06\t11\t69\t30\t03\t73 Lake Technical Services Ltd.\t07\t07\t66\t30\t03\t73 \t10\t07\t60\t30\t03\t73 \t20\t04\t70\t30\t03\t73 \t04\t01\t63\t30\t03\t73 \t12\t08\t55\t30\t03\t73 \t22\t06\t71\t30\t03\t73 \t01\t01\t71\t30\t03\t73 Les Placements Roland Halle inc.\t07\t01\t71\t30\t03\t73 \t13\t08\t65\t30\t03\t73 \t01\t03\t50\t30\t03\t73 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 51176-0 Pierre Desjardins.51176-0 Director of the Companies Service.Chartes \u2014 Charters \u2014 demandes d'abandon de Applications for Surrender of Bruno Cyr Compagnie Ltée Bruno Cyr Compagnie Ltée Prenez avis que la compagnie « Bruno Cyr Compa- Notice is given that \"Bruno Cyr Compagnie Liée\" gnie Ltée » demandera au ministre des institutions will apply to the Minister of Financial Institutions, financières, compagnies et coopératives la permission Companies and Cooperatives for leave to surrender its d'abandonner sa charte.charter.Le procureur de la compagnie.Me Nolan Filiatrault, Notary, 51178-0 Me Nolan Filiatrault, notaire.51178 Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2001 Ilavmor Investments Ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Havmor Investments Ltd.», constituée en vertu de la Loi des compagnies, fera demande pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire, 51179-0 Raymond Bertrand.Havmor Investments Ltd.Notice is hereby given that \"Havmor Investments Ltd.», incorporated under the provisions of the Companies Act, will apply for leave to surrender its charter.Raymond Bertrand, 51179-0 Secretary.Rawmatcx Ltd.Prenez avis que la compagnie « Rawmatcx Ltd.» demandera au ministre des institutions financières compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2 mars 1973.Les procureurs de la compagnie, 51180-o Greenblatt, Ginsberg & Assoc-s.Rawmatcx Ltd.Take notice that \"Rawmatcx Ltd.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, March 2, 1973.Grebnblatt, Ginsberg & Assocs., 51180-o Attorneys for the Company.Three Rivers Chevrolet (1969) Limited Trois-Rivibres Chevrolet (1969) limitée Avis est par les présentes donné que « Three Rivers Chevrolet (1969) Limited \u2014 Trois-Rivières Chevrolet (1969) limitée » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 4e jour d'octobre, 1972.Le secrétaire-trésorier, 51181-0 Réal Provost.Three Rivers Chevrolet (1969) Limited Trois-Rivibres Chevrolet (1969) limitée Notice is hereby given that \"Three Rivers Chevrolet (1969) Limited \u2014Trois-Rivières Chevrolet (1969) limitée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, Québec, this 4th day of October, 1972.Real Provost, 51181-1) Secretary-Treasurer.Frank Brcsee Inc.Prenez avis que la compagnie « Frank Bresee Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le secrétaire, 51235-0 Gaston Baribeau.Frank Brescc Inc.Notice is given that \"Frank Bresee Inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Gaston Baribeau, 51235-0 Secretary.Famous Coffee Shop Inc.Prenez avis que la compagnie « Famous Coffee Shop Inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 19 mars 1973.Le procureur de la compagnie, 51237-0 Me Jacques Bélanger.Famous Coffee Shop Inc.Take notice that \"Famous Coffee Shop Inc.\" having its head office at Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, March 19, 1973.Me Jacques Bélanger, 51237-o Attorney for the company.Les Pétroles Coaticook Inc.Prenez avis que la compagnie « Les Pétroles Coaticook Inc.» demandera au ministre «les institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Signé à Windsor, Québec, ce 27e jour de février 1973.Le procureur de la compagnie, 51239-0 Armand Marier, notaire.Les Pétroles Coaticook Inc.Notice is given that \"Les Pétroles Coaticook Inc.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Signed in Windsor, Québec, this 27th day of February, 1973.Armand Marier, Notary, 51239 Attorney for the Company. 2002 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Confection Christians Inc.Avis est par la présente donné que « Confection Christiane Inc.», une compagnie incorporée sous la Loi des compagnies, ayant son siège social i'i Montréal, Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, dans le but d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 8e jour de mars 1973.Les procureurs de la requérante, 51236-0 GllEENBLATT, GODINSKY & RESIN.Confection Christiane Inc.Notice is hereby given that \"Confection Christiane Inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the said Companies Act.Dated at Montreal, this 8th day of March, 1973.Ghee.nbi.att, Godinsky & Resin, 51236-0 Attorneys for Applicant.Macalton Inc.Avis est ici donné que « Macalton Inc.», une compagnie incorporée selon la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, avec l'intention d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Québec, le 10 janvier 1973.Le secrétaire, 51238-0 Jules Behxatchez.Macalton Inc.Notice is given that \"Macalton Inc.\", a company incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Québec, January 10, 1973.Jules Berxatchez, 51238 Secretary.Le Reflet de Bedford Inc.Avis est donné que « Le Reflet de Bedford Inc.», compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coojiérativcs la permission d'abandonner sa charte.Donné à Farnham, ce 27e jour de mars 1973.Le procureur de la compagnie, 51240-o Jean-Paul Couture.Le Reflet de Bedford Inc.Notice is hereby given that \"Le Reflet de Bedford Inc.\", incorporated under the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Farnham, this 27th day of March 1973.Jean-Paul Couture, 51240-o Attorney for the Company.Restaurant L'Artisan inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Restaurant L'Artisan inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, ce 27e jour de mars 1973.Le notaire, 51265-0 Me Jacques Forest.Restaurant L'Artisan inc.Notice is hereby given that the compagny \"Restaurant L'Artisan inc.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to accept the surrender of its charter.Grindstone, Magdalen Islands, this 27th day of March 1973.Me Jacques Forest, 51265-0 Notary.Succession Hon.John Ileam inc.Avis est donné que la compagnie « Succession Hon.John Hearn inc.», une compagnie constituée d'après la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Québec, fera application auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Québec, ce 29e jour de mars 1973.Les procureurs de la requérante, Rivard, Hickson, 51267-o Sirois & Lemieux.Succession Hon.John Hearn inc.Notice is hereby given that \"Estate Hon.John Hearn inc.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Dated at Québec, this 29th day of March, 1973.Rivard, Hickson, Sihois & Lemieux, 51267-o Attorneys for the Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" U 2003 Sérigraphie Bilodeau Limitée Prenez Avis que la compagnie « Sérigraphie Bilodeau Limitée\" demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le président de la compagnie, 51241-0 Georges Bilodeau.Sérigraphie Bilodeau Limitée Notice is given that \"Sérigraphie Bilodeau Limitée\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Georges Bilodeau, 51241-o President.Charles Guindon inc.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Charles Guindon inc.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, ce 27c jour de mars 1973.Le notaire, 51266-0 Me Jacques Forest.Charles Guindon inc.Notice is hereby given that the compagny \"Charles Guindon inc.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to accept the surrender of its charter.Grindstone, Magdalen Islands, this 27th day of March, 1973.Me Jacques Forest, 51266-0 Notary.Divers Compagnies Miscellaneous Companies A.J.Campbell & Co.Limited La compagnie « A.J.Campbell & Co.Limited » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire, J.A.Campbell.51183-0 6154-50 A.J.Campbell & Co.Limited Notice is given that \"A.J.Campbell & Co.Limited\" has changed the number of its directors from 5 to 4.51183-0 J.A.Campbell, Secretary.6154-50 Conseil Régional de Développement de la Région Administrative de Québec La corporation « Conseil Régional de Développement de la Région Administrative de Québec » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 37.Le président, J.-Artiiur Bédard.51184-0 2878-71 Les Constructions Canitron ltée Canitron Construction Ltd.La compagnie « Les Constructions Canitron ltée \u2014 Canitron Construction Ltd.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Moses Salzberg.51185 724101 Fabraply Inc.La compagnie « Fabraply Inc.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, G.A.Tramley.51187 3032-68 Conseil Régional de Développement de la Région Administrative de Québec Notice is given that the \"Conseil Régional de Développement de la Région Administrative de Québec\" has increased the number of its directors from 4 to 37.J.-Artiiur Bédard, President.51184 2878-71 Les Constructions Canitron ltée Canitron Construction Ltd.Notice is given that \"Les Constructions Canitron ltée \u2014 Canitron Construction Ltd.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Moses Salzberg, Secretary.51185-0 724101 Fabraply Inc.Notice is given that \"Fabraply Inc.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.G.A.Tramley, Secretary.3032-68 51187-o 2004 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Den Packaging Corp.Société d'Emballage Den La compagnie ' Den Packaging Corp.\u2014 Société d'Emballage Den » donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.1a secrétaire, Harvey Uline.5118G 721197 Les Galeries des îles ltée La compagnie « Les Galeries des îles ltée » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 8 à 7.Le secrétaire, Rolland Brodeur.51188-0 722047 Lauzier Électrique inc.Lauzier Electric Inc.La compagnie « Lauzier Électrique inc.\u2014 Lauzier Electric Inc.» donne avis qu'elle 'a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.La secrétaire, Mme Jacqueline Denobile Lauzier.61189-0 3021-65 Portuguese Fish Market Ltd.Marché de Poissons Portugais ltée La compagnie « Portuguese Fish Market Ltd.\u2014 Marché de Poissons Portugais ltée » donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, José Medeiros.51190 4494-67 Dcn Packaging Corp.Société d'Emballage Den Notice is given that \"Den Packaging Corp.\u2014 Société d'Emballage Den\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Harvey Uline, Secretary.51186-0 721197 Les Galeries des îles ltée Notice is given that \"Les Galeries des îles ltée\" bas changed the number of its directors from 8 to 7.51188 Rolland Brodeur, Secretary.722047 I .a ii /.ici- Électrique Inc.Lauzier Electric inc.Notice is given that \"Lauzier Électrique inc.\u2014 Lauzier Electric Inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Mrs.Jacqueline Denobile Lauzier, Secretary.51189 3021-65 Portuguese Fish Market Ltd.Marché de Poissons Portugais ltée Notice is given that \"Portuguese Fish Market Ltd.\u2014 Marché de Poissons Portugais ltée\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Jose Medeiros, Secretary.51190-o 4494-67 Studio de Santé Sihouctte de St-Lambert liée Silhouette Health Studio of St.Lambert Ltd.La compagnie « Studio de Santé Silhouette de St-Lambert ltée \u2014 Silhouette Health Studio of St.Lambert Ltd.2 donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, Joseph Marleau.51191 4128-69 Cardeau Inc.La compagnie « Cardeau Inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Jean-Guy Rochefort.51228-0 4157-69 Chamex inc.La compagnie « Chamex inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, R.Ouellet.51232-o 723697 Studio de Santé Silhouette de St-Lambert ltée Silhouette Health Studio of St.Lambert Ltd.Notice is given that \"Studio de Santé Silhouette de St-Lambert ltée \u2014 Silhouette Health Studio of St.Lambert Ltd.\" has changed the number ot its directors from 3 to 4.Joseph Marleau, Secretary-Treasurer.51191-0 4128-69 Cardeau Inc.Notice is given that \"Cardeau Inc.\" has decreased the number of its directors from 5 to 3.Jean-Guy Rochefort, Secretary.51228-o 4157-69 Chamex inc.Notice is given that \"Chamex inc.\" has decreased the number of its directors from 4 to 3.R.Ouellet, Secretary.51232 723697 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2005 Le Centre Communautaire de Pointe-aux-Trcmbles inc.La corporation « Le (\"entre Communautaire de Pointe-aux-Trembles inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 3.Le secrétaire, Roger Marchand.51229-0 725100 Centre de Distributions Soleil (C.D.S.) inc.La compagnie « Centre de Distributions Soleil (C.D.S.) inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Hahti.y Doyle.51230-o 725149 Le Centre du Dindon inc.La compagnie « Le Centre du Dindon inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Gabriel Boisjoli.51231-0 1895-66 Haas & Cavalière inc.La compagnie « Haas & Cavalière inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Roger Petit.51233-0 11497-58 Théâtre Marist inc.La corporation « Théâtre Marist inc.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le président, Aario A.Marist.51234-q 721111 Le Centre Communautaire de Pointe-aux-Trembles inc.Notice is given that \"lx Centre Communautaire de Pointe-aux-Trembles inc.\" has decreased the number of its directors from 7 to 3.Roger Marchand, Secretari/.51229 725100 Centre de Distributions Soleil (C.D.S.) inc .Notice is given that \"Centre de Distributions Soleil (C.D.S.) inc.\" has decreased the number of its directors from 4 to 3.Hahti.y Doyle, Secretary.51230 725149 Le Centre du Dindon inc.Notice is given that \"Le Centre du Dindon inc.\" has decreased the number of its directors from 5 to 3.Gabriel Boisjoli, Secretary.51231 1895-66 Haas & Cavalière inc.Notice is given that \"Haas & Cavalière inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Roger Petit, Secretari/.51233 11497-58 Théâtre Marist inc.Notice is given that \"Théâtre Marist inc.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Aario A.Marist, President.51234 721111 La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné que « La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) » (Libre de responsabilité personnelle), a diminué de 7 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Gérard Grosof.51192 1795-70 La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) (Libre de responsabilité personnelle) Notice is given that \"La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ)\" (Libre de responsabilité personnelle), has changed the number of its directors from 7 to 5.Gérard Grosof, Secretary.51192-o 1795-70 Sièges sociaux Head Offices Chamex inc.La compagnie « Chamex inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 450, rue Thibeau, Cap-dc-la-Madelcine, à Sherbrooke.Le secrétaire, R.Ouellet.51245-0 723697 Chamex inc.Notice is given that \"Chamex inc.\" has transferred its head office from 450 Thibeau Street, Cap-de-la-Madeleine, to Sherbrooke.R.Ouellet, Secretary.51245 723697 2006 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Central Security Agency Limited Agence Centrale de Sécurité limitée Lu compagnie « (\"entrai Security Agency Limited \u2014 Agence Centrale de Sécurité limitée » donne avis qu'elle à changé son siège social du numéro 1, Carré West-inount, bureau 945, Westmount, au numéro 3300, boulevard Cavendish, bureau 40, Montréal.Le président, Mario Viviani.51193-0 5841-68 Concorde Electrique limitée Concorde Electric Limited La compagnie \" Concorde Électrique limitée \u2014 Concorde Electric Limited » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 5902, Place Villier, Brassard, au numéro 1102, rue Victoria, Lemoync.Le secrétaire, Guy Buchanan.51194-0 3345-69 Les Distributions D.Q.B.Inc.D.Q.B.Distribution Inc.Avis est donné que la compagnie « Les Distributions D.Q.B.inc.\u2014 D.Q.B.Distribution Inc.», constituée en corporation en date du 12 mars 1973 et ayant son siège social dans le district de Montréal, a établi son bureau au 43, rue Dieppe, Place Bona venture, à Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 22e jour de mars 1973.(Sceau) Le président, 51195-0 Jean-Pierre Gadoury.Central Security Agency Limited Agence Centrale de Sécurité limitée Notice is given that \"Central Security Agency Limited\u2014 Agence Centrale de Sécurité limitée\" bas transferred its head office from 1 Westmount Square, Room 945, Westmount, to 3300 Cavendish Boulevard, Room 40, Montreal.Mario Viviani, President.51193 5841-68 Concorde Électrique limitée Concorde Electric Limited Notice is given that \"Concorde Électrique limitée \u2014 Concorde Electric Limited\" has transferred its head office from 5902 Place Villier, Brossard, to 1102 Victoria Street, Lemoyne.Guy Buchanan, Secretary.51194 3345-69 Les Distributions D.Q.B.Inc.D.Q.B.Distribution Inc.Notice is given that \"Les Distributions D.Q.B.inc.\u2014 D.Q.B.Distribution Inc.\", incorporated on March 12, 1973, and having its head office in the city of Montreal, has established its office at 43 Dieppe Street, Place Bonaventure, Montreal.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as its head office.Given at Montreal, this 22nd day of March, 1973.(Seal) Jean-Pierre Gadouby, 51195-0 President.Texpro Inc.Avis est donné que la compagnie «Texpro Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 1er jour de décembre 1972, ayant son bureau principal dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 1450 de la rue City Councillors.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce premier jour tie mars, mil neuf cent soixante-treize.Le président, 51202-o Robert Lemire.Texpro Inc.Notice is given that \"Texpro Inc.\", incorporated by letters patent dated the first day of December, 1972, having its head office in the City of Montreal, has established its office at 1450 City Councillors Street.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Given at Montreal, this first day of March one thousand nine hundred seventy-three.Robert Lemire, 51202 President.Sauna Neptune Inc.Avis est donné que la compagnie « Sauna Neptune Inc.», constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies (Québec) par lettres patentes en date du 11 septembre 1972, a établi son siège social au 456 ouest, rue Lagauchetière, dans la cité de Montréal.Montréal, ce 4c jour d'octobre 1972.Le président, Lorne Halliday.51256-0 72-5030 Sauna Neptune Inc.Notice is hereby given that \"Sauna Neptune Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act (Québec) by letters patent dated September 11, 1972, has established its head office at 456 Lagauchetière Street West in the City of Montreal.Montreal, this 4th day of October 1972.Lorne Halliday, President.51256 72-5030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2007 Glace Frigon inc.Frigon Icc Inc.Avis est par les présentes donné que « Glace Frigon inc.\u2014 Frigon Icc Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 21 décembre 1972 et ayant son siège social à Longueuil, a établi son principal bureau au numéro 90 Boul.Ste-Foy, en la ville de Longueuil, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Longueuil, ce 28e jour de février 1973.(Sceau) Le ¦président, Conrad Frigon.51197-0 72-9660 Greater York Group Ltd.Le Groupe Grand York ltée On donne avis par les présentes que la compagnie « Greater York Group Ltd.\u2014 Le Groupe Grand York ltée», constituée en corporation en vertu des dispositions de la Loi des compagnies par lettres patentes émises le 1er jour de février 1973, et ayant son siège social en la ville de Montréal, dans ladite province, a établi son bureau au 5, place Ville Marie, édifice I.B.M., 12e étage, Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté ce 15e jour de mars 1973.(Sceau) Le secrétaire, 51198 Clifford Waxman.Glace Frigon inc.Frigon Ice Inc.Notice is hereby given that \"Glace Frigon inc.\u2014 Frigon Ice Inc.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Companies Act, on December 21st 1972, and having its head office in Longueuil, has established its head office at 90 Stc-Foy Blvd.in the city of Longueuil, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Longueuil, this 28th day of February, 1973.(Seal) Conrad Frigon, President.51197-o 72-9660 Greater York Group Ltd.Le Groupe Grand York ltée Notice is hereby given that \"Greater York Group Ltd.\u2014 Le Groupe Grand York ltée\", incorporated Under the provisions of the Companies Act by letters patent granted on the 1st day of February, 1973, and having its head office in the City of Montreal, in the saiil Province, has established its office at 12th Floor, I.B.M.Building, 5 Place Ville Marie, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated this 15th day of March, 1973.(Seal) Clifford Waxman, 51198-o Secretary.Perspective G.R.S.Haut Richelieu Inc.Avis est donné que la compagnie « Perspective G.R.S.Haut Richelieu Inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 février 1973 et ayant son siège social à Saint-Jean, district d'Iberville, a établi son bureau au numéro 176 de la rue Jacques-Cartier.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré comme étant son siège social.Saint-Jean, ce 26 février 1973.Le secrétaire, 51199-o André Filion.Sovac ltée Avis est donné que la compagnie « Sovac ltée », constituée en corporation par lettres patentes en date du 22c jour de janvier 1973, et ayant son siège social dans le district de Montréal, a établi son bureau au 1460 rue Union, Montréal. compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé à Montréal, ce 19c jour de mars 1973.(Sceau) Le président, 51201-o Albert Ricard.Perspective G.H.S.Haut Richelieu Inc.Notice is given that \"Perspective G.R.S.Haut Richelieu Inc.\", incorporated by letters patent on February 12, 1973, and having its head office at Saint-Jean, district of Iberville, has established its office at 176 Jacques-Cartier Street.From the date of this notice, the said office is considered by the company as being its head office.Saint-Jean, February 26, 1973.André Filion, 51199-0 Secretary.Sovac liée Notice is hereby given that \"Sovac ltée\", company incorporated by letters patent on the 22nd day of January 1973, and having its head office in Montreal, has established its office at 1460 Union Street, Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Signed at Montreal, this 19th day of March 1973.(Seal) Albert Ricard, 51201-O President. 2008 QUÉBEC OEE ICI AL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.Uf Ferme Avicole Stc-Marie inc.La compagnie \" Ferme Avicole Ste-Marie inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 40.rue St-Antoine, Saint-Jean-Baptistc, au numéro 368, Seigniory Crescent, Mont St-Hitaire.La secrétaire, Nicole Gendron.51196-0 .729516 Ferme Avicole Ste-Maric inc.Notice is given that \"Ferme Avicole Ste-Marie inc.\" has transferred its head office from 40 St.Antoine Street, St.Jean-Baptiste to 368 Seigniory Crescent, Mont St.Hilaire.Nicole Gendron, Secretary.51196 729516 La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) (Libre de responsabilité personnelle) La société « La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) » (Libre de responsabilité jicrsonnclle) donne avis qu'elle a transporté son siège social de Itouyn au 1010, rue Sainte-Catherine ouest, Montréal.Le secrétaire, Gérard Grosof.51200 1795-70 Belter Made Shoulder Straps Inc.On donne avis par les présentes que la compagnie « Better Made Shoulder Straps Inc.'1, constituée en corporation par lettres patentes en date du 7e jour d'avril 1060, et ayant son siège social au 3637, boulevard Métropolitain est, suite 602, Saint-Michel, Montréal, a transporté ledit siège social au 9494, boulevard Saint-Laurent, suite 702, en les ville et district de Montréal, province de Québec.À compter de la date du present avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à 'Montréal, ce 7e jour de décembre 1972.Le secrétaire.Jack Starke.51242 11228-60 Banio Inc.Avis est donné que la compagnie « Bamo Inc.», constituée en corporation le 2 février 1973, par lettres patentes ayant son siège social dans la ville de Longueuil, district de Montréal, a établi son bureau au numéro 1321 de la rue St-Thomas.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Longueuil, ce 28c jour de mars 1973.La présidente, 51243-0 Alma Banner.L.Doucet ltée La compagnie « L.Doucet ltée » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 8335, rue Alphonse Desjardins, Saint-Léonard, au numéro 4200, rue Majeau, Montréal-Nord.Le secrétaire, Éloi Doucet.51250-o 4995-64 La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouesl Québécois limitée (SIMNOQ) (Libre de responsabilité personnelle) Notice is given that \"La Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ)\" (Libre de responsabilité personnelle) has transferred its head office from Rouvn, to 1010 Ste.Catherine Street West, Montreal.Gerard Grosof, Secretary.51200-O 1795-70 Better Made Shoulder Straps Inc.Notice is hereby given that \"Better Made Shoulder Straps Inc.\", incorporated by letters patent on the 7th day of April, 1960, and having its head office at 3637 Metropolitan Boulevard East, Suite 602, St.Michel, Montreal, has moved it to 9494 St.Lawrence Boulevard.Suite 702, in the City and District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 7th day of December, 1972.Jack Starke, Secretary.51242-0 11228-60 Bamo Inc.Notice is given that \"Bamo Inc.\", incorporated on February 2nd, 1973 by letters patent and having its head office in the town of Longueuil, District of Montreal, has established its office at 1321, St-Thomas Street.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being the head office of the company.Given at Longueuil, this 2Sth day of March 1973.Alma Banner, 51243-o President.L.Doucet ltée Notice is given that \"L.Doucet ltée\" has transferred its head office from 8335 Alphonse Desjardins Street, St.Léonard, to 4200 Majeau Street, Montreal North.Éloi Doucet, Secretary.51250 4995-64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105- année, n° Il 2009 J.P.Brassard inc.Avis est donné que la compagnie \" J.P.Brassard inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 août 1972 et ayant son bureau principal à Montréal, a établi son siège social au numéro 321, rue Caty.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à L'Assomption ce treize novembre mil neuf cent soixante-douze.Le procureur de la compagnie, Bertrand Allard, notaire.51244-e 724442 Comité du Centenaire de Baie-dcs-Sables Inc.Avis est donné par la présente que la corporation « Comité du Centenaire de Baie-des-Sables inc.», constituée en corporation par lettres patentes en date du quinzième jour de février mil neuf cent soixante-douze, et ayant son bureau principal dans le village de Baic-dcs-Sables a établi son bureau au numéro 36 rue de la Mer.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son bureau principal.Donné à Matane, ce 28e jour de novembre 1972.Le secrétaire, Madeleine Massé.51246-0 720892 Crédit Bombardier ltée Avis est donné que la compagnie « Crédit Bombardier ltée», constituée par lettres patentes datées du 20 mars 1973 et ayant son siège social à Valcourt, P.Q., a établi son bureau principal à Valcourt, district de Bedford.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, P.Q., ce 20e jour de mars 1973.Le président, 51247-o Claude Fontaine.J.P.Brassard inc.Notice is given that \"J.I\\ Brassard inc.\", incorporated by letters patent dated August 9, 1972, and having its head office in Montreal, has established its head office at 321 Caty Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in L'Assomption, this thirteenth day of November, one thousand nine hundred and seventy-two.Bertrand Ai.i.ahd, Notary, Attorney for the Company.51244 721112 Comité du Centenaire de Baie-des-Sables Inc.Notice is hereby given that the \"Comité du Centenaire de Baie-des-Sables inc.\", incorporated by letters patent dated the fifteenth day of February, one thousand nine hundred and seventy-two, and having its principal office in the Village of Baie-dcs-Sables, has established its office at 36 de la Mer Street.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the corporation as being its head office.Given in Matane, this 28th day of November, 1972.Madeleine Massé, Secretari/.51246 720892 Bombardier Crédit Ltd.Notice is hereby given that \"Bombardier Credit Ltd., \"incorporated by letters patent dated March 20, 1973, and having its head office in Valcourt, P.Q., has established its head office at Valcourt in the District of Bedford.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the Company as being its head office.Given at Montreal, P.Q., this 20th day of March, 1973.Claude Fontaine, 51247-o President.Daraco Inc.Avis est par les présentes donné que « Daraco Inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, le 21 août 1968, a établi son siège social à 500 Place d'Armes, suite 1200, Montréal, P.Q.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 13e jour de décembre 1972.(Sceau) Le secrétaire, 51249-0 John M.Kilpatrick.Daraco Inc.Notice is hereby given that \"Daraco Inc.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Québec Companies Act dated August 21, 1968, has established its head office at.500 Place d'Armes, Suite 1200, Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 13th day of December, 1972.(Seal) John M.Kilpatrick, 51249-0 Secretary. 2010 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.14 Lambert-Starke Products Corp.On donne avis par les présentes que la compagnie « Lambert-Starke Products Corp.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 22e jour de février 1968, et ayant son siège social à Montréal, où son bureau était situé au 3637, boulevard Métropolitain est, suite 602, a transporté ledit bureau au 9494, boulevard Saint-Laurent, suite 702, en les ville et district de Montréal, province de Québec.A compter dé la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montreal, ce 15e jour de janvier 1973.Le trésorier, Bertram Lambert.51252 837-68 Matério inc.La compagnie « Matério inc.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 355, rue Dupuy, Québec, au numéro 302, 23e Rue, Charny.Le secrétaire, Gaston Deslauriers.51253-0 8583-49 Piedmont Investments Ltd.Investissements Piedmont ltée Avis est par les présentes donné que la compagnie Piedmont Investments Ltd.\u2014 Investissements Piedmont ltée », corporation constituée en vertu de l'article 18 de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 25 janvier, 1973 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au 800 Place Victoria, Suite 2401.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Toronto, Ontario, ce 22e jour de mars 1973.(Sceau) Le secrétaire, 51254-0 G.E.A.Pacaud.Lambcrt-Starke Products Corp.Notice is hereby given that \"Lambert-Starke Products Corp.\", incorporated by letters patent on the 22nd day of February, 1968, and having its head office in Montreal, where its office was situated at 3637 Metropolitan Blvd.East, Suite 602, has moved it to 9494 St.Lawrence Blvd., Suite 702, City and District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 15th day of January, 1973.Bertram Lambert, Treasurer.51252-o 837-68 Matério inc.Notice is given that \"Matério inc.\" has transferred its head office from 355 Dupuy Street, Québec, to 302 -23rd Street, Charny.Gaston Deslauriers, Secretary.51253 8583-49 Piedmont Investments Ltd.Investissements Piedmont ltée Notice is hereby given that \"Piedmont Investments Ltd.\u2014 Investissements Piedmont ltée\", a corporation constituted under Section 18 of the Companies Act by letters patent dated January 25, 1973 and having its head office in the City of Montreal, has established its office at Suite 2401,800 Victoria Square.Upon, from and after the date of this notice, the said office will be considered by the Company as being its head office.Dated at Toronto, Ontario, this 22nd day of March, 1973.(Seal) G.E.A.Pacaud, 51254-0 Secretary.Les Productions du Verseau inc.Avis est donné que la compagnie « Les Productions du Verseau inc.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 12c jour de février 1973, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 245, avenue Victoria.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 15e jour de mars 1973.Les procureurs de la compagnie, Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud.51255-o 730617 Les Productions du Verseau inc.Notice is given that \"lyes Productions du Verseau inc.\", incorporated by letters patent issued under Part I of the Companies Act, on the 12th day of February, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 245 Victoria Avenue.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Given in Montreal, this 15th day of March, 1973.Desjardins, Duciiarme, Desjardins, Tellier, Zk.by & Michaud, Attorneys for the Company.51255 730617 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril I97à, 105' année, n° 14 2011 Crown Holdings Ltd.On donne avis par les présentes que la compagnie « Crown Holdings Ltd.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 6e jour de mars 1969, et ayant son siège social à Montréal, où son bureau était situé au 2050, rue Mansfield, Montréal, a transporté ledit bureau au 1255, rue Université, suite 600, en les ville et district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, ce 14e jour de février 1973.Le secrétaire-trésorier, Hannah Winer.51248 980-69 Labo S.M.Inc.Avis est donné que la compagnie « Labo.S.M.Inc.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 7 novembre 1972 et ayant son siège social au numéro 449, boulevard Queen nord, dans la cité de Sherbrooke, P.Q., jusqu'à aujourd'hui l'a transporté au numéro 16, rue Metcalfe, à Sherbrooke, P.Q.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Ce 22e jour de janvier 1973.Le président, Bernard Poulin.5125l-o 725975 J.Roger Tremblay limitée Avis est donné que la compagnie « J.Roger Tremblay limitée », constituée en corporation sous la première partie de la Loi des compagnies par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec, en date du dix-neuf février mil neuf cent soixante-treize (1973), a établi son bureau au numéro 747 Avenue D'Astous, à Hauterive.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Baie Comeau, ce douzième jour de mars mil neuf cent soixante-treize (1973).Dame Pierrette Dotoub Tremblay.51257-0 73-0723 Crown Holdings Ltd.Notice is hereby given that \"Crown Holdings Ltd.\", incorporated by letters patent on the 6th day of March, 1969, and having its head office in Montreal, where its office was situated at 2050 Mansfield Street, .Montreal, has moved it to 1255 University Street, Suite 600, City and District of Montreal, Province of Québec.Prom and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 14th day of February, 1973.Hannah Winer, Secretary-Treasurer.51248-0 980-69 Labo S.M.Inc.Notice is given that \"Labo.S.M.Inc.\", incorporated under Part I of the Companies Act on November 7, 1972, and having its head office at 449 Queen Boulevard North, in the City of Sherbrooke, P.Q., until today, has transferred it to 16 Metcalfe Street, in Sherbrooke, P.Q.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.This 22nd day of January, 1973.Bernard Poulin, President.51251 725975 J.Roger Tremblay limitée Notice is hereby given that the company \"J.Roger Tremblay limitée\", incorporated under Part I of the Québec Companies Act by letters patent bearing date the nineteenth day of February nineteen hundred and seventy-three (1973), issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec has established its office at number 747, Avenue D'Astous, in the City of Hauterive.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Baie Comcau, this twelfth day of March nineteen hundred and seventy-three (1973).Dame Pierrette Dltouh Tremblay.51257-0 73-0723 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Debra Lee Fishman Avis est donné que Debra Lee Fishman, étudiante, domiciliée au 1875 de la rue Kenilworth, Ville Mont-Royal, district de Montréal.s'adressera au ministre de la Justice en vue de faire changer son nom en celui de Debra Lee Fisher.51167-13-2-0 Debra Lee Fishman.Change of name \u2014 Act Applications Debra Lee Fishman Take notice that Debra Lee Fishman, student, domiciled at 1875 Kenilworth Rd., Town of Mt.Royal, district of Montreal, will apply to the minister of Justice to have her name changed to Debra Lec Fisher.51167-13-2-0 Debra Lee Fishman. 2012 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Vladimir Atamancc (A i man) Avis est donné que M.Vladimir Atamanec (Atman), Statisticien, demeurant à 89, 8e Avenue, à Ville Lasalle, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Walter Atman, ledit changement de nom devant servir à son épouse, née Simonne Basque, de la même adresse.Le procureur du requérant, 5U22-13-2-0 Bernard Bourdon, avocat.Ilovannes Haroutyoun Km labia lia» Avis est par les présentes donné que Hovanncs Haroutyoun Kutahialian résidant à 14333 Yates Crescent, Ville de Pierrefonds, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de John H.Are-vian, ledit changement de nom devant bénéficier à sa femme Dikranuhi Alexanian et des enfants mineurs liera et Krikor-Hratch, lesdits noms devant servir à toutes fins légales.Montréal, Québec, le 19 mars 1973.Le procureur du requérant, 51121-13-2-0 Monroe A.Charlap.Robert Litowitz Avis est donné que Robert Litowitz, vendeur, de 3410, rue Victoria, appartement 202, Lacliine, Québec, présentera, en vertu de la Loi du changement de nom une requête au ministre de lu Justice du Québec, afin ((lie son nom soit changé en celui de Robert Litowitz Murphy, et que le nom de son épouse, Cheryl Lynn Litowitz, née Boswell, de la même adresse, soit aussi changé en celui de Murphy.Daté ù Dorval, Province de Québec, ce 15c jour de mars 1973.Les procureurs du requérant, 51153-13-2 MM.Amaron and Stead, Avocats.Vladimir Atamanec (Atman) Notice isgiven that Mr.Vladimir Atamanec (Atman), statistician, residing at 89 - 8th Avenue, in the City of Lasalle, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Walter Atman; the said change of name shall concern his wife, née Simonne Basque, of said address.Bernard Bourdon, advocate, 51122-13-2 Attorney for the petitioner.Ilovannes Haroutyoun KutabiaUan Notice is hereby given that Ilovannes Haroutyoun Kutahialian residing at 14333 Yates Crescent in the City of Picrrefonds, District of Montreal will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an Order changing his name to that of John H.Areviari, the said change of name to benefit his wife Dikranuhi Alexanian and his minor children Hera and Krikor-Hratch, the said names to serve for all legal purposes.Montreal, Québec, March 19, 1973.Monroe A.Charlap, 51121-13-2-0 Attorney for the petitioner.Robert Litowitz Take notice of the Application of Robert Litowitz, salesman, of 3410 Victoria Street, Apt.202, Lachine, Québec, to the Minister of Justice of Québec under the Change of Name Act, that his name be changed to Robert Litowitz Murphy and that the surname of his wife, Cheryl Lynn Litowitz, née Boswell, of the same address be also changed to Murphy.Dated at Dorval, Province of Québec this 15th day of March, 1973.Messrs.Amaron and Stead, Advocates, 51153-13-2-0 Attorneys for the Petitioner.Josepb-Cajetan Marcien Roy Avis est par la présente donné que Joseph-Cajetan Marcien Roy, agent du service extérieur du gouvernement canadien, domicilié au 33, rue Perras, à Hull, district de Gatineau, présentera au ministre de la justice du Québec une requête visant à obtenir un décret changeant son nom en Jean-Philippe Martin Roy.51156-13-2-0 Marcien Rot.Joseph-Cajetan Marcien Roy Notice is hereby given that Joseph-Cajetan Marcien Roy, Foreign Service Officer of the Canadian Government, domiciled at 33, Perras Street, Hull, District of Gatineau, will present a petition to the Minister of Justice of the Government of Québec with a view to obtaining an Order in Council changing his name to Jean-Philippe Martin Roy.51156-13-2-0 Marcien Rot.Arman Topakoglu Avis est par les présentes donné que Arman Topakoglu, domicilié et résidant au 3333 Edouard Montpetit, appartement 20, ville de Montréal, province de Québec, s'adressera au ministre de la justice pour que son nom soit changé en celui de Annan Topakian.Le procureur du requérant, 51130-13-2-o Gordon L.McGilton.Arman Topakoglu Notice is hereby given that Arman Topakoglu, residing and domiciled at 3333 Edouard Montpetit, Apartment 20, in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to Arman Topakian.Gordon L.McGilton, 51130-13-2-o Attorney for applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2013 Kurt I.Kleinberger On donne avis par les présentes que Kurt I.Klein-berger, domicilié et résidant en les ville et district de .Montréal, au 3555, côte des Xeiges, Regency Appurt-ments, appartement 212, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom de Kurt I.Kleinberger en celui de Kurt I.Kkyne, le tout conformément aux dispositions de la Loi du changement de nom.Montréal, le 13 mars 1973.Le procureur du requérant, 51112-12-2 Kurt I.Kleinberger (Klyne).Kurt I.Kleinberger Notice is hereby given that Kurt I.Kleinberger, domiciled and residing in the City and District of Montreal at 3555 Côte des Neiges, Regency Apartments, Apartment 212, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for the adoption of an order changing his name from Kurt I.Kleinberger to Kurt I.Klyne, the whole as provided for in the provisions of the Change of Name Act.Montreal, March 13, 1973.Kurt I.Kleinberger (Klyne), 51112-12-2-0 Attorneys for petitioner.Henry Borowczyk Prenez avis que Henry Borowczyk, résidant au 3605 rue St-Urbain à Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom en celui de Henry Borow.Montréal, le 23 mars 1973.Les procureurs, 51262-14-2-0 Champagne, Massé & Feuland.Henry Borowczyk Notice is hereby given that Henry Borowczyk, residing at 3605 St.Urbain Street, Montreal, will present to the Lieutenant-Governor in Council an application to change his name to Henry Borow.Montreal, this March 23, 1973.Champagne, Massé & Ferland, 51262-14-2-o Attorneys.Joseph Paul Richard Charbonneau Avis est donné par les présentes que monsieur Joseph Paul Richard Charbonneau, plombier, demeurant au 86, nie Corbeil, Hull, dans le district judiciaire de Hull, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Paul Richard Fortin.Hull, le 29 mars 1973.Le notaire et procureur, 51263-14-2-0 Jacques Laframboise.Joseph Paul Kichurd Charbonneau Notice is hereby given that Mr.Joseph Paul Richard Charbonneau, plumber, residing at 86 Corbeil Street, Hull, in the district of Hull will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing his name to that of Joseph Paul Richard Fortin.Hull, March 29, 1973.Jacques Laframboise, 51263-14-2-0 Notary and Attorney.Lawrence Michael Burg Avis est, par les présentes, donné que Lawrence Michael Burg, de la cité de Montréal, et demeurant à 7370 Ostell Crescent, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille, de Burg à Geringer.Les procureurs du requérant, Robinson, Siieppard, Borenstein, 51264-14-2-0 Shapiro & Flam.Lawrence Michael Burg Notice is given that Lawrence Michael Burg, gentleman of the City and District of Montreal and therein residing at 7370 Ostell Crescent, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorization to change his surname from Burg to Geringer.Robinson, Siieppard, Borenstein, Shapiro & Flam, 51264-14-2-0 Attorneys for Petitioner.Salimi Ghobril Avis est donné par les présentes que Salim Ghobril, professeur, domicilié au 1029, rue Sud à Cowansville, district de Bedford, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour demander un décret changeant son nom en celui de Salim Gabriel et que ce changement bénéficiera aussi à son épouse Rose-Marie _Bonin-Ghobril et à leur enfant mineure Marie Evelyne Geneviève Ghobril.Montréal, le 26 mars 1973.Iœs procureurs du requérant, Villeneuve, Pigeon, Clément 51207-14-2-o & Guilbeault.Salim Ghobril Notice is hereby given that Salim Ghobril, teacher of full age of majority, residing at 1029 Sud Street in Cowansville, district of Bedford, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Salim Gabriel and that same name shall also benefit his wife Rose-Marie Bonin-Ghobril and his minor child Marie Evelyne Geneviève Ghobril.Montreal, March 26, 1973.Villeneuve, Pigeon, Clément, & Guilbeault, 51207-14-2-o Attorneys for petitioner.-J 2014 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.U Henrietta Louise Chauvin On donne avis par les présentes que Henrietta Louise Chauvin, veuve de Donald Gordon, résidant et domiciliée au 3940, chemin Côte-des-Neige, appartement 1) 52, en la ville de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'obtenir un décret changeant son nom de jeune tille en celui de Henrietta Louise Norma Hobbs.Le procureur de la requérante, 51206-14-2 Gordon L.McGilton.Henrietta Louise Chauvin Notice is hereby given that Henrietta Louise Chauvin, widow of the late Donald Gordon, residing and domiciled at 3940 Côte des Neiges Road, Apt.D 52, in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her maiden name to Henrietta Ixmise Norma Hobbs.Gordon L.McGilton.51206-14-2-o Attorney for applicant.Sherley Grégoire Avis est par les présentes donné que Mademoiselle Sherley Grégoire, résidant et domiciliée au 2825 Tur-bide, en la ville de Giffard, désire présenter une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Sylvie Grégoire.Québec, ce 22e jour de février 1973.Les procureurs de la requérante, Lafrenière, Maltais, 51208-14-2-o Langlois & Doyon.Sherley Grégoire Notice is hereby given that Miss Sherley Grégoire, residing and domiciled at 2825 Turbide, in the city of Giffard, wishes to submit a request to the Minister of Justice for an order changing her name to that of Sylvie Grégoire.Québec, this 22nd day of February, 1973.Lafrenière, Maltais, Langlois & Doyon, 51208-14-2-o Attorneys for the petitioner.Walter Elwood Symonds On donne avis par les présentes que Walter Elwood Symonds, camionneur, domicilié au 397, 8e avenue.Ville LaSalle, dans le district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Walter Elwood Marsman.Montréal, Québec, le 20 mars 1973.Le procureur du requérant, 51210-14-2 Alfred M.West, cr.Walter Elwood Symonds Notice is hereby given that Walter Elwood Symonds, truck operator, domiciled at 397 - 8th Avenue, Ville LaSalle, in the District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Walter Elwood Marsman.Montreal, Que., March 20th, 1973.Alfred M.West, q.c, 51210-14-2-o Attorney for the petitioner.Marie Sylvie Pichette Avis est donné que Marie Sylvie Pichette, Rang 3, Thetford Mines, comté et district de Mégantic, fille majeure de monsieur et madame Marcel Pichette du même lieu, demandera au ministre de la justice de changer son nom en celui de Marie Nathalie Pichette.Thetford Mines, le 20 mars 1973.Le procureur de la requéraide, 51221-14-2-0 Me W.James Johnson.Marie Sylvie Pichette Notice is given that Marie Sylvie Pichette, Range 3, Thetford Mines, County and District of Mégantic, spinster, daughter of Mr.and Mrs.Marcel Pichette of the same place, will apply to the Minister of Justice to change her name to that of Marie Nathalie Pichette.Thetford Mines, March 20, 1973.Me W.James Johnson, 51221 -14-2 Attorney for the petit ioner.Arie Sadan Avis est donné par les présentes, que Arie Sadan, enseignant, domicilié et résidant au 162, 3e Avenue, à Chibougamau, province de Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil, d'émettre une ordonnance changeant son nom pour Lucian Sadan.Chibougamau, le 2 mars 1973.Les procureurs du requérant, 51258-14-2-0 Côté, Gilbert & Ouellet.Arie Sada n Notice is hereby given that Arie Sadan, teacher, residing at 162-3th Avenue, Chibougamau, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Lucian Sadan.Chibougamau, March 2, 1973.Côté, Gilbert & Ouellet, 51258-14-2-0 Attorneys for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° 14 2015 Katherine April Lcfebvre Avis est donné que Katherine April I.cfebvre, étudiante, domiciliée au 271, nord, rue Belvédère, Sherbrooke, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Katherine April Raff an.Le procureur de la requérante, 51209-14-2-o Tiiomas W.Leonard, notaire.Katherine April I.cfebvre Notice is hereby given that Katherine April I.cfebvre, student, domiciled at 271 Belvedere Street North, Sherbrooke, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to that of Katherine April Ralfan.Thomas W.Leonard, Notary, 51209-14-2-o Attorney for the petitioner.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Jacqueline Raymondc Catherine Dubé Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 917 du 21 mars 1973, d'effectuer le changement de nom de Marie Jacqueline Raymonde Dubé en celui de Jacqueline Raymonde Catherine Dubé.Québec, le 26 mars 1973.51214-0 Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, cr.Jacqueline Raymonde Catherine Dubé It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Jacqueline Raymonde Dubé to that of Jacqueline Raymonde Catherine Dubé by order number 917 dated March 21, 1973.Québec, March 26, 1973.51214 Robert Normand, q.c, Deputy Minister of Justice.Joseph Gilles Jean Patry Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 918 du 21 mars 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph Wilfrid Gilles Patry en celui de Joseph Gilles Jean Patry.Québec, le 26 mars 1973.51214-0 Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, cr.Joseph Gilles Jean Patry It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Wilfrid Gilles Patry to that of Joseph (idles Jean Patry by order number 918 dated March 21, 1973.Québec, March 26, 1973.51214 Robert Normand, q.c, Deputy Minister of Justice.Marie Josèphe Riopcl H a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 919 du 21 mars 1973, d'effectuer le changement de nom de Marie Josèphe en celui de Marie Josèphe Riopel.Québec, le 26 mars 1973.51214-0 Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, cr.Marie Josèphe Riopel It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Josèphe to that of Marie Josèphe Riopel by order number 919 dated March 21, 1973.Québec, March 26, 1973.51214 Robert Normand, q.c, Deputy Minister of Justice.Paul Boulos Michel Yamine H a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 920 du 21 mars 1973, d'effectuer le changement de nom de Boulos Michel Yamine en celui de Paul Boulos Michel Yamine.Québec, le 26 mars 1973.51214-0 Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, cr.Paul Boulos Michel Yamine It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Boulos Michel Yamine to that of Paul Boulos Michel Yamine bv order number 920 dated March 21, 1973.Québec, March 26, 1973.51214 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice. 2016 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.U Demandes à la Législature Applications to Legislature Club de Golf New Glasgow (1966) Inc.Avis est par les présentes donné cpie le « Club de Golf New Glasgow (11166) Inc.» s'adressera à l'Assemblée Nationale afin de faire voter un amendement aux articles six (6) et huit (S) de la loi le constituant en corporation (1971, S.Q., 125 privé), de façon à ce que le capital-actions autorisé de la corporation soit de $450,000 divisé en 1,200 actions ordinaires d'une valeur nominale de $375 chacune au lieu de 600 actions ordinaires d'une valeur nominale de $750 chacune.Donné à New Glasgow, ce 23e jour de mars 1973.Le procureur de la corporation, 51173-13-4-0 Claude Gratton.Club de Golf New Glasgow (1966) Inc.Notice is hereby given that \"Club de Golf New Glasgow (1966) Inc.\" will apply to the National Assembly to request the passing of an amendment to sections six (6) and eight (8) of the Act (Q.S.1971, Chapter 125) incorporating it, so that the corporation's authorized share capital may be of $450,000, divided into 1,200 common shares of a nominal value of $375 each, instead of 600 common shares of a nominal value of $750 each.Given at New Glasgow, this 23rd day of March, 1973.Claude Ghatton, 51173-13-4 Attorney for the Corporation.Commander Nickel Copper Mines Ltd.(Libre ension plan for the members of the Council; 3.To amend certain sections of divisions 6 and 7 of the Cities and Towns Act respecting municipal elections and particularly, but without limitation, sections 128, 131, 132, 135, 137, 139, 147, 148,150, 181, 182, 196 and 246; 4.To provide the members of the Council with compensation for their attendance at Committee and Commission sittings; 5.To amend the Cities and Towns Act for the City, as regards public notices; 6.To modify the penalties for violations of traffic regulations, particularly the provisions respecting speed and the relinquishment of vehicles on private property; 7.Notwithstanding the first paragraph of section 427 of the Cities and Towns Act, to enable the City to amend its master plan in such a way as to integrate the Laurentian Ward and to make it possible to amend its zoning bylaw in conformity with such plan; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1978, 105- année, n' U 2017 8.Pourvoir à l'entretien d'hiver des rues et des trottoirs de la municipalité et autoriser à souffler la neige sur les trottoirs et terrains privés; 9.Établir, par règlement, le genre de service approprié pour l'enlèvement de la neige et obliger les propriétaires à payer la taxe qui sera imposée pour assurer ce service; 10.Ratifier l'ouverture d'un certain nombre de rues conformément aux dispositions de l'article 429 de la Loi des cités et villes; 11.Permettre à la Ville «l'augmenter la limite de vitesse sur les chemins, rues ou boulevards qui lui sont cédés pour entretien par le ministère de la Voirie; 12.Mise à la retraite de certains employés et paiement de rentes; 13.Permettre par règlement de taxer les distributrices et autres jeux mécaniques; 14.Établir une nouvelle procédure d'adoption des règlements d'emprunts pour la réfection et construction de rues, trottoirs, chaînes de rues, éclairage, signalisation routière, égouts et aqueduc et porter à §10,000,000 le montant des emprunts que la Ville peut contracter pour ces travaux; 15.Autoriser par règlement la création d'un fonds spécial pour acquérir, pour fins résidentielles ou publiques, des immeubles situés dans le territoire connu sous le nom de Pointe Ste-Foy ainsi que d'autres lots situés dans les limites de la municipalité et le droit de disposer des immeubles ainsi acquis; 16.Établir une nouvelle procédure d'expropriation pour fins de voirie, d'égouts et d'aqueduc; 17.Autoriser la Ville à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou autres droits immobiliers pour fins d'habitation, y compris tout immeuble nécessaire pour fins publiques, communautaires ou autres; _ 18.Permettre par règlement la construction, l'administration et l'entretien d'un système de conduits souterrains pour y placer des fils de télégraphe, téléphone, télévision, éclairage électrique, de distribution de force motrice, cables et lignes de transmission.Et pour toutes autres fins.Québec, ce 6 mars 1973.Le procureur de la ville de Ste-Foy, 50974-1 l-4-o Hubert Walters.Avis divers Ville de Cowansville Avis public est par les présentes donné «pie Cowansville entend se prévaloir des dispositions de l'article 430 de la Loi des cités et villes, tel que ci-après reproduit, pour le lot ci-après mentionné : * Lot 172-1 du cadastre et livre de renvoi officiel du Village de Cowansville, borné au nord par la rue Church et par partie du lot 172 (non divisé), à l'est par partie 8.To provide for the maintenance of the streets and sidewalks of the Municipality during the winter and to the blowing or snow onto sidewalks and private property; 9.To establish, by means of a bylaw, an appropriate type of snow-removal service and to oblige proprietors to pay the tax which will be imposed to ensure such service; 10.To approve the opening of a number of streets in conformity with the provisions of section 429 of the Cities and Towns Act; 11.To enable the City to increase the speed limit on roads, streets or boulevards whose maintenance has been transferred to it by the Department of Roads.12.To make arrangements for the retirement of certain employees and for the payment of annuities; 13.To permit, by means of a bylaw the imposition of a tax on vending machines and other mechanical amusement devices; 14.To establish a new procedure for the adoption of loan bylaws for the repair and construction of streets, sidewalks, curbs, lighting, road signs systems, sewers and waterworks, and to raise to S10.000,000 the amount of the loans which the City may contract for such works; 15.To authorize, by means of a bylaw, the establishment of a special fund for the purchase, for residential or public purposes, of immoveables located within the territory known by the name of Pointe Ste.Foy as well as of other lots located within the limits of the Municipality; to grant the right to dispose of the immoveables thus acquired; 16.To establish a new expropriation procedure with regard to roads, sewers and waterworks; 17.To authorize the City to purchase, for housing purposes, by mutual agreement or by expropriation, any immoveable or other rights on immoveables, including any immoveable required for public, community or other purposes; 18.To allow, by means of a bylaw, the construction, administration and maintenance of a system of underground conduits in which to place telegraph, telephone, television, electrical lighting, power supply wires, cables and transmission lines.And for all other purposes.Québec, March 6, 1973.Hubert Walters, 50974-11-4 Attorney for the City of Ste.Foy.Miscellaneous Notices Town of Cowansville Public notice is hereby given that Cowansville will avail itself of the provisions of article 430 of the Cities and Towns Act, which reads as follows, for the lot hereinafter mentioned: \"Lot 172-1 of the official plan and book of reference of the Village of Cowansville bounded to the north by Church Street and part of lot 172 (not divided), to the 2018 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U du lot 172 (non divisé), au sud par le lot 177-1 à l'ouest par partie du lot 172 (non divisé).» Plan et description technique préparés par Monsieur Guy Migué, ariienteur-géomètre, en date du 30 janvier 1973.Les rues ou ruelles ouvertes au public depuis au moins dix ans deviennent propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités suivantes : 1.Le conseil approuve par résolution une description de toutes rues ou ruelles ou de toute partie de celles-ci pour lesquelles la municipalité entend se prévaloir du présent article; 2.Cette description doit être faite d'après un plan cadastral et un livre de renvoi faits et déposés conformément à la Loi du cadastre (chap.320); 3.L'original de cette description doit être déposé au bureau du Grellicr de la municipalité et une copie certifiée par un ari>entcur-géoniètrc doit être déposée au bureau du registrateur de la division d'enregistrement où se trouvent les terrains visés; 4.Le Greffier de la municipalité fait publier deux fois dans la Gazelle officielle du Québec et dans un journal quotidien circulant dans la municipalité, avec un intervalle d'au moins trois mois et d'au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant: a) le texte intégral du présent article; 6) une description sommaire des rues ou ruelles concernées; c) une déclaration à l'effet que les formalités prévues aux paragraphes 1 ci 2 ont été accomplies.Tout droit auquel des tiers pourraient prétendre à la propriété du fonds desdites rues ou ruelles est prescrit s'il n'est pas exercé par action devant le tribunal compétent dans l'année suivant la dernière publication dans la Gazelle officielle du Québec.La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard du rues ou ruelles sur lesquelles elle a prélevé une taxe au cours des dix années précédentes.Le plan et description technique de la rue jx>ur laquelle Cowansville se prévaut, du présent article, sont déposés au bureau du greffier ainsi qu'au bureau d'enregistrement de Missisquoi.Un certificat est également donné à l'effet que Cowansville a accompli les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article.Donné à Cowansville, ce 26e jour de mars 1973.Le greffier, 51211-14-2-0 Georges H\".Bernier.Club de Motoiieige Arvida ific.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 29e jour de janvier 1973, constituant en corporation sans capital-actions, sous le nom de « Club de Motoneige Arvida inc.», les membres actuels de « Club Auto-Neige Arvida inc.», déjà constituée en corporation le ou vers le 14 janvier 1970, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).east by part of lot 172 (not divided), to the south by lot 177-1, to the west by part of lot 172 (not divided).\" Plan and technical description prepared by Mr.Guy Migué, surveyor on January 30th, 1973.The streets or lanes open to the public for ten years or more shall become the property of the municipality upon the observance of the following formalities: 1.The council shall approve by resolution a description of all streets or lanes or parts thereof with respect to which the municipality proposes to avail itself of this section ; 2.Such description shall be made according to an official plan and book of reference made and deposited in conformity with the cadastre Act; 3.The original of such description must be deposited in the office of the clerk of the municipality and a copy certified by a land surveyor shall be deposited in the office of the registrar of the registration division where the lands concerned are situated; 4.The clerk of the municipality shall cause to be published twice in the Québec Official Gazelle and in a daily newspaper circulating in the municipality, with an interval of not less than three months nor more than four months between publication, a notice containing: (a) the full text of this section; (b) a summary description of the streets or lanes concerned ; (c) a declaration to the effect that the formalities prescribed by paragraphs 1 and 2 have been observed.Any right that third parties might claim to the ownership of the site of the said streets or lanes shall be prescribed unless exercised by suit before the competent court within one year after the last publication in the Québec Official Gazelle.The municipality cannot avail itself of this section with respect to streets or lanes on which it has levied any tax within the preceding ten years.The plan and technical description of the street for which Cowansville avail itself of the present article are deposited at the office of the clerk of Cowansville and also at the registration office of Missisquoi.It is also certified that Cowansville has fulfilled all requirements provided in paragraphs 1 and 2 of the said article.Given at Cowansville, this 26th day of March, 1973.Georges H.Bernier, 51211-14-2-0 Town Clerk.Club de Motoneige Arvida inc.Notice is given that under Part IDT of the Companies Act, letters patent, bearing date the 29th day of January, 1973, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating without share capital, under the name of \"Club de Motoneige Arvida inc.\", the present members of \"Club Auto-Neige Arvida inc.\", already incorporated on or about January 14, 1970, pursuant to the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, chapter 298). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 106' année, n° U 2019 Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $200,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Arvida, district judiciaire de Chicoutimi.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.51176-o 730269 Succession Mario Antonio Nicolo Avis est donné par les présentes conformément aux articles 660 et suivants du Code civil : 1° Que par acte d'acceptation, reçu devant Me \u2022Fuies Prévost, notaire, le 7 février 1973, dont copie est enregistrée à Montréal, sous le numéro 2405110, le 8 février 1973, Madame Mariantonia Zappavigna veuve de Mario Antonio Nicolo demeurant au 6760, rue Aima, appartement 3, en la Ville de Montréal a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de son mari ledit Mario Antonio Nicolo, en son vivant, commerçant, ayant demeuré au 6760, rue Aima, appartement 3, en ia Ville de Montréal lequel est décédé le 23 novembre 1972.2° Que par acte d'acceptation, reçu devant Me Jules Prévost, notaire, le 27 février 1973, dont copie est enregistrée à Montréal, sous le numéro 2408867, le 28 février 1973, Madame Mariantonia Zappavigna veuve de Mario Antonio Nicolo es-qualité de tutrice à ses enfants mineurs Giuseppe, Marinella et Enrico Nicolo, demeurant au 6760, nie Aima, appartement 3, en la Ville de Montréal, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de son mari, ledit Mario Antonio Nicolo, en son vivant commerçant, ayant demeuré au 6760, rue Aima, appartement 3, en la Ville de Montréal, lequel est décédé le 23 novembre 1972.Le notaire, 51203-o Jules Prévost.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav acquire and hold is to be limited, is «200,000.The head office of the new corjioration is in Arvida, Judicial District of Chicoutimi, Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.51176 730269 Estate of Mario Antonio Nicolo Notice is hereby given pursuant to articles 660 et seq.of the Civil code: 1.That by deed of acceptance passed before Mtre Jules Prévost, notary on February 7th, 1973, whereof copy was registered at Montreal under number 2405110 on February 8th 1973, Mrs Mariantonia Zappavigna widow Antonio Nicolo, residing at 6760, Alma Street Apt.3, Montreal has accepted under the benefit of inventory the estate of Mario Antonio Nicolo deceased of November 23, 1972.2.1 hat by deed of acceptance passed before Mtre Jules Prévost, notary on February 27th 1973, whereof copy was registered at Montreal under number 2408867 on February 28th 1973, Mrs Mariantonia Zappavigna widow Mario Antonio Nicolo, acting as tutrix to her children Giuseppe, Marinella and Enrico Nicolo, residing at 6760 Alma Street Apt.3, Montreal has accepted under the benefit of inventory the estate of Mario Antonio Nicolo, deceased of November 23, 1972.Jules Prévost, 51203-o Notary.Nominations Avis est donné que, par l'arrêté en conseil numéro 3962-72, du 20 aéeembre 1972, il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer conseils en loi de la reine, par commission sous le grand sceau de la province, les avocats et membres du Barreau du Québec aont les noms suivent, savoir: MM.Claude Benoît, Jules Duchesneau, Guy Gilbert, John H.Gomery, Irving J.Halpcrin, Dov Kravetz, Bernard Lasnicr, André Laurence, Jules Lcavitt, Jean-Jacques L'Heureux, Paul Mailloux, Jacques Mongeau, Lawrence-A.Poitras, Michcl-E.Rioux, Lomer Rivard, Pierre Vcrdy, tous de Montréal; Pierre Bergeron, de Chicoutimi; Huguette-M.Charette, de Hull; Richard Drouin, de Québec; Louis Jolin, de Waterloo; J.-Pierre Rousseau, de Saint-Jérôme; Dewey Zaor, de Sherbrooke.Québec, le 26 mars 1973.Le sous-procureur général adjoint, 51214-0 Jean A la rie.Appointments Notice is given that, by Order in Council number 3962-72, dated December 20, 1972, the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to appoint as Queen's Counsel learned in the law, by commission under the Great Seal of the Province, the lawyers and Members of the Bar of Québec whose names are listed below, namely: Messrs.Claude Benoît, Jules Duchesneau, Guy Gilbert, John H.Gomery, Irving J.Halperin, Dov Kravetz, Bernard Lasnicr, André Laurence, Jules Leavitt, Jean-Jacques L'Heureux, Paul Mailloux, Jacques Mongeau, Lawrence-A.Poitras, Michcl-E.Rioux, Lomer Rivard, Pierre Verdy, all of Montreal; Pierre Bergeron, of Chicoutimi; Huguette-M.Charette, of Hull; Richard Drouin, of Québec; Louis Jolin, of Waterloo; J.-Pierre Rousseau, of St.Jérôme; Dewey Zaor, of Sherbrooke.Québec, March 26, 1973.Jean Alarie.51214 Assistant Deputy Attorney General. 2020 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Présidents d'élection Conformément à l'article 3 de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (lois de 1972, chapitre 4), il a plu à son honneur le lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil executif, par commission, sous le grand sceau, de faire, pour remplir la charge de président d'élection, les nominations suivantes: Retu rn ing-Officers According to section 3 of the Act amending the Territorial Division Act (statutes of 1972, chapter 4), his honour the Lieutenant-Governor has been pleased, with the advice and consent of the Executive Council to appoint by commission under the great seal, to fill the office of rcturning-officer the person whose name follows: District électoral Nom, prénoms Profession ou occupation Domicile Electoral district Name, Christian names Profession or calling Domicile Abitibi-Est.Bonneville, Robert.Administrateur.Val d'Or Rimouski.Michaud, André.Comptable.Pointe-au-Père Québec, le 28 mars 1973.Le président général des élections.Juge de la Cour provinciale, 51259-0 François Drouin.Québec, March 28, 1973.François Drouin, Judge of the Provincial Court, 51259-o The Chief Returning-Officer.Avis est donné qu'il a plu an lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, les nominations suivantes: Québec, le 7 février 1973.Me Jean Fournier, avocat, nommé délégué général du gouvernement du Québec à Londres, Angleterre, conformément à l'arrêté en conseil portant le numéro 3373, du 6 octobre 1971, en vertu de la Loi des agents ou délégués généraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 208, modifié par le chapitre 23 des lois de 1966-67), telle nomination ayant pris effet à compter du 1er août 1971.Monsieur Guy Poliquin, nommé délégué général du gouvernement du Québec à New York, États-Unis d'Amérique, conformément à l'arrêté en conseil portant le numéro 3374, du 6 octobre 1971, en vertu de la Loi des agents ou délégués généraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 208, modifié par le chapitre 23 des lois de 1966-67), telle nomination ayant pris effet à compter du 1er septembre 1971.Monsieur Jean Deschamps, nommé délégué général du gouvernement du Québec à Bruxelles, Belgique, conformément à l'arrêté en conseil portant le numéro 2695-72, du 13 septembre 1972, en vertu de la Loi des agents ou délégués généraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 208, modifié par le chapitre 23 des lois de 1966-67), telle nomination ayant pris effet à compter du 1er janvier 1973.Québec, le 7 mars 1973.Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointments by commission under the Great Seal of the Province: Québec, February 7, 1973.Mr.Jean Fournier, lawyer, appointed Delegate-general of the Province of Québec in London, England, by Order in Council number 3373, dated October 6, 1971, under the Agents-General and Delegates-General Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 208, amended by the Chapter 23 of the Statutes of 1966-67), the foregoing to take effect from August 1st, 1971.Mr.Guy Poliquin, appointed Delegate-general of the Province of Québec in New York, United-States of America, by Order in Council No.3374, dated October 6, 1971, under the Agents-General and Delegates-General Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 208, amended by the Chapter 23 of the Statutes of 1966-67), the foregoing to take effect from September 1st, 1971.Mr.Jean Deschamps, appointed Delegate-general of the Province of Quél>ec in Brussells, Belgium, by Order in Council No.2695-72, dated September 13, 1972, under the Agents-General and Delegates-General Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 208, amended by the Chapter 23 of the Statutes of 1966-67), the foregoing to take effect from January 1st, 1973.Québec, March 7, 1973.51214-0 Le sous-procureur général adjoint, Jean Alarie.51214 Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2021 Québec, le 20 décembre 1972.Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, les nominations suivantes: Aie Michel Dumaine, avocat et membre du Barreau du Québec, 1960, rue Louvigny, Douville, nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, avec résidence dans la cité de Saint-Hyacinthe ou dans le voisinage immédiat, ledit Me Michel Dumaine, vu sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe li de l'article 4S2 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, le tout à compter du 15 janvier 1973.Québec, le 23 janvier 1973.Me Louis-Philippe Bouchard, avocat et membre du Barreau du Québec, de Québec, nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec, avec résidence dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat, ledit Me Louis-Philippe Bouchard, vu sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe b de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, le tout à compter du 23 janvier 1973.Québec, le 23 janvier 1973.Me Adolphe Prévost, avocat et membre du Barreau du Québec, de Montréal, nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal, avec résidence dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat, ledit Me Adolphe Prévost, vu sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe b de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, le tout à compter du 23 janvier 1973.Québec, le 27 mars 1973.Québec, December 20.1972.Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointments by commission under the Great Seal of the Province: Me Michel Dumaine, lawyer, member of the Bar of Québec, 1960, Louvigny Street, Douville, appointed under section 117 of the Courts of .Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments), Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act in the entire Province but particularly ami without restriction in the Judicial District of St.Hyacinthe, with residence in the City of St.Hyacinthe or in the immediate vicinity, the said Me Michel Dumaine, in view of his appointment by the Lieutenant-Governor in Council as Judge of the Provincial Court, being empowered, under paragraph (b) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from January 15, 1973.Quebec, January 23, 1973.Me Louis-Philippe Bouchard of Québec, lawyer, member of the Bar of Québec, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964.Chapter 20 and amendments), Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act in the entire Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Québec, with residence in the City of Québec or in the immediate vicinity, the said Me Louis-Philippe Bouchard, in view of his appointment by the Lieutenant-Governor in Council as Judge of the Provincial Court, being empowered, under paragraph (b) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from January 23, 1973.Québec, January 23, 1973.Me Adolphe Prévost, lawyer, member of the Bar of Québec, Montreal, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments).Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act in the entire Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Montreal, with residence in the City of Montreal or in the immediate vicinity, the said Me Adolphe Prévost, in view of his appointment by the Lieutenant-Governor in Council as Judge of the Provincial Court, being empowered, under paragraph (b) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from January 23, 1973.Québec, March 27, 1973.50214-o Le sous-procureur général adjoint, Jean Alarie.50214 Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General. 2022 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau île la province, la nomination suivante: Québec, le 28 février 1973.Me Pierre Leblanc, avocat, domicilié au 461, rue Notre-Dame, ('ap-dc-la-Madelcine: coroner pour les districts judiciaires de T rois-Rivières, de Saint-Maurice et de Joliette, avec juridiction seulement sur le district électoral de Maskinongé.Québec, le 28 mars 1973.Le sous-procureur gênerai adjoint, 51214-o Jean Alarie.Caisses d'épargne et de crédit Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointment, by commission under the Great Seal of the Province: Québec, February 28, 1973.Me Pierre Leblanc, lawyer, domiciled at 461 Notre-Dame Street, Cap-de-la-Madeleine: coroner for the Judicial Districts of Trois-Itivières, St.Maurice and Joliette, with jurisdiction in the electoral District of Maskinongé only.Québec, March 28, 1973.Jean Alarie, 51214 Assistant Deputy Attorney General.Savings and Credit Unions Caisse Populaire Belvédère (Lot des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement, adopté le sei/.e janvier 1973 par la « Caisse populaire S.S.-Martyrs' Québec\", changeant son nom en celui de « Caisse Populaire Belvédère ».Québec, le 11 mars 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopérât ires, 51216-0 Fernaxd Laloxde.La Caisse Populaire Desjardins de Laval des Rapides (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné (pie le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 27 décembre 1972 par « La Caisse populaire Desjardins de Laval des Rapides », modifiant son territoire qui était celui de « La cité de Laval-des-Ra-piiles » en celui de « La municipalité de la ville de Laval ».Québec, le 19 mars 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopérât ires.5l217-o Fernaxd Laloxde.Caisse Populaire Duberger (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le douze décembre 1972 par « La Caisse Populaire St-Frunçois-Xavier.Québec », changeant son nom en celui de « Caisse Populaire Duberger », et également changeant le territoire de cette caisse qui est « la paroisse St-François-Xavier, Québec», en celui de « la ville de Québec Québec, le 17 mars 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 51218-0 Fernand Lalonde.Caisse Populaire Belvédbre (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on the sixteenth day of January, 1973, by the \"Caisse Populaire SS.-Martyrs' Québec\", changing its name to that of \"Caisse Populaire Belvédère\".Québec, March 14, 1973.Fernaxd Laloxde, Deputy Minister of Financial Institutions, 51216 Companies and Cooperatives.La Caisse Populaire Desjardins de Laval des Rapides (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on December 27, 1972, by \"La Caisse Populaire Desjardins de Laval-de.s-Rapides\", modifying its territory which was \"the City of Laval-des-Rapides\" to that of \"the Municipality of the City of Laval\".Québec, March 19, 1973.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions.51217 Companies and Cooperatives.Caisse Populaire Duberger (Savi?igs and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on the twelfth day of December, 1972, by \"La Caisse Populaire St-François-Xavier.Québec\", changing its name to that of \"Caisse Populaire Duberger\".and also changing the territory of this union which is \"the Parish of St.François-Xavier, Québec\", to that of \"the City of Québec\".Québec, March 17, 1973.Fernaxd Laloxde, Deputy Minister of Financial Institutions, 51218 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" U 2023 Proclamations Proclamations HUGUES LAPOINTE Canada, Province de Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du village d'Aylmer, comprenant le lot 2192, située dans la division d'enregistrement de Gatineau, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit village qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Gatineau, à Maniwaki; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt de ces plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Gatineau, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du village d'Aylmer; A ces cause, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 650-73, du 28 février 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent», qu'il y a lieu: à) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Gatineau, à Maniwaki, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du village d'Aylmer, comprenant le lot 2192, située dans la division d'enregistrement de Gatineau; b) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article HUGUES LAPOINTE Canada, Province of Québec.[L.S.) ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Village of Aylmer, comprising lot 2192.located in the Gatineau Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan ; WHEREAS the correct plan of this part of the said Village signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Gatineau Registration Division Office, in Maniwaki, by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil (.'ode, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Gatineau Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Milage of Aylmer; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 650-73, dated February 28, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant, to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Gatineau Registration Division Office, in Maniwaki, of the original plan and book of reference of a part of the Village of Aylmer, comprising lot 2192, located in the Gatineau Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (b) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2024 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du village d'Aylmer; c) de rappeler «pie, dans les deux ans qui suivent celle dale, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de lerre désigné par ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement, par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; oser le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fi lèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Quéliec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-huitième jorr de février en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 89 51214-o Therefore, with the advice and consent of Our Executive Coum il, expressed in a decree numbered 653-73, dated February 28, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Hooks of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Sept-îles Registration Division Office, in Sept-îles, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Phélypeaux, comprising Block D, located in the Sept-îles Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Phélypeaux; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed : Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-eighth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 89 51214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 arril 1973, 105- année, n\" !>, 2031 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront, Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article I de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre «les terres et torêts, un plan d'une partie du canton de Reclus, comprenant le lot 2 (île Verte ou Bronson), située dans la division d'enregistrement de Témisca-mingue, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et torêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Témiscamingue à Ville-Marie; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt de ces plan et livre de renvoi originaires dans la division «l'enregistrement de Témiscamingue, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Reclus.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret («irtant le numéro 656-73, du 28 février 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la propositions du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II «le ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le sition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Ix>i du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320).ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dis]>ositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Saint-Jean, à Saint-Jean, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie de la paroisse de Saint-Jean, comprenant le lot 240, située dans la division d'enregistrement de Saint-Jean; 6) de fixer à la date de la pulication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie de la paroisse de Saint-Jean ; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette .date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné par ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement, par dépôt, «l'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.pared, uniler his superintendence, a correct plan of a part of the Parish of St.Jean, comprising lot 240, located in the St.Jean Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whekeas the correct plan of this part of the said Parish signed by the Minister of bands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the St.Jean Registration Division Office, in St.Jean, by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the St.Jean Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Parish of St.Jean : therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 748-73, dated March 7, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the St.Jean Registration Division Office, in St.Jean, of the original plan and book of reference of a part of the Parish of St.Jean, comprising lot 240, located in the St.Jean Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Parish of St.Jean; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; («/) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern arc hereby required to take notice and to govern themselves accordingly. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" U 2037 En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aime l'honorable Hugues Lapointe, c.p.ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hotel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce septième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Ai.auie.Folio: 93 51214-0 In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c., q.c.Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this seventh day of March in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command.Jean Ai.ahie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 93 51214 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA.Avis d'annulation de permit et de certificat d'enregistrement Attendu que « National Union Firc Insurance Company of Pittsburgh, Pa.», dont le siège social est situé à Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec la « American Home Assurance Company » dont le siège social est situé à New York, New York, États-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 31 décembre 1972, et lequel contrat de réassurance a pris effet le 1er janvier 1973; Attendu que « American Home Assurance Company » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que < National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa.», s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances: En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa.», sont annulés à compter du 31 décembre 1972 ; Donné au bureau du Sendee des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 19 février 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le surintendant des assurances, 51113-13-2-0 Roger-A.Camarairb.National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA.Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa.\", whose head office is situated at Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"American Home Assurance Company\" whose head office is situated at New York, New York, United States of America, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 31st of December 1972, with effect from the 1st of January 1973; Whereas \"American Home Assurance Company\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"National Union Firc Insurance Company of Pittsburgh, Pa.\", has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa.\", are cancelled as from the 31st of December 1972; Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 19th of February 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 51113-13-2-0 Superintendent of Insurance. 2038 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.14 Granite State Insurance Company Avis d'annulalion de permis el de certificat d'en reg 1st rem eu t Attendu que « (ïranitc State Insurance Company », dont le siège social est situé à Manchester, New Hampshire, États-Unis d'Amérique, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec lu « New Hampshire Insurance Company » dont le siès;e social est situé à Manchester.New Hampshire, Etats-Unis d'Amérique, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 31 décembre 11)72, et lequel contrat de réassurance a prix effet le 1er janvier 1973; Attendu que « New Hampshire Insurance Company » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu (pie « Granité State Insurance Company» s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné (pie le permis et le certificat d'enregistrement de « Granite State Insurance Company» sont annulés à compter du 31 décembre 1972; Donné au bureau du service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 19 février 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopérât ires de la Province, Le surintendant des assurances, 51111-13-2-0 Rogeb-A.Camaraire.Granite State Insurance Company Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"Granite State Insurance Company\", whose head office is situated at Manchester, New Hampshire, United States of America, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"New Hampshire Insurance Company\" whose head office is situated at Manchester, New Hampshire United Stales of America, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 31st of December 1972, with effect from the 1st of January 1973; WlIEREAS \"New Hampshire Insurance Company\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"Granite State Insurance Company\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"Granite State Insurance Company\" are cancelled as from the 31st of December 1972; Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 19th of February 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 51114-13-2-0 Superintendent of Insurance.The Sovereign Mortgage Insurance Company La Souveraine.Compagnie d'Assurance d'Hypothèques Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné, par les présentes, que « The Sovereign Mortgage Insurance Company \u2014 La Souveraine, Compagnie d'Assurance d'Hypothèques», enregistrée sous le numéro 752, a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1323, qui l'autorise à compter du 24 janvier 1973, à effectuer dans la province des contrats relatifs au genre d'assurance suivant: hy]x>thèques.Le siège social de la compagnie est situé à 1320, rue Yonge, Toronto 290, Ontario.La compagnie a nommé monsieur Lionel-A.Norman-deau, 1320 boulevard Graham, Montréal 304, son procureur dans la province.Donné au bureau du service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 7 mars 1973.Pour le ministre des institutionsfiancières, compagnies et coopératives de la province./,c surintendant des assurance*.51148-13-2-0 Roger-A.Camaraire.The Sovereign .Mortgage Insurance Company La Souveraine, Compagnie d'Assurance d'Hypothèques Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"The Sovereign Mortgage Insurance Company \u2014 La Souveraine, Compagnie d'Assurance d'Hypothèques\", registered under number 752, has obtained the license and certificate of registry number 1323, authorizing it, as from the 24th of January 1973, to undertake in the province contracts of insurance in the following class: Mortgage.The head office of the company is situated at 1320 Yonge Street, Toronto 290, Ontario.The company has appointed Mr.Lionel A.Norman-deau, 1320 Graham Boulevard, Montreal 304, its attorney in the province.Given at the ( fh'ce of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, the 7th of March 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger.-A.Camaraire, 51148-13-2-0 Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1073, 105' année, n° 11, 20I59 Insmor Mortgage Insurance Company Insmor Compagnie d'Assurance d'Hypothèque Avis d'émission de permit et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que '< Insmor Mort-gage Insurance Company \u2014 Insmor Compagnie d'Assurance d'Hypothèque », enregistrée sous le numéro 753 a obtenu le permis et le certificat «l'enregistrement numéro 1327 qui l'autorise à compter du 16 février 1973 à effectuer dans la Province des contrats relatifs au genre d'assurance suivant: hypothèque.Le siège social de la compagnie est situé à 4 ouest, rue King, Toronto, Ontario.La compagnie a nommé monsieur Robert Tru-chon, ll.i.100 Place d'Youville, Suite 800.Québec, son procureur dans la Province.Donné au bureau du Service «les assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 28 mars 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances, 51272-14-2-0 Rorts indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Ad rcsse Address Rapports non produits Returns not filed L'Agence Fleur de Lys inc.L'Alliance Produits de Beauté inc.L'Assomption gaz & pétrole liée.L'Assomption Holdings Corp.L'Auberge du Grand Métis ltée.Jean-Luc Bombardier inc.Jean Bonnor charpente d'acier inc.La Boutique des fleurs Lasalle inc.La Boutique du connaisseur inc.La Calèche Motel-Hôtel inc.La Caverne inc.La Centrale d'ambulances inc.La Chevalerie St-Sauveur inc.La Cie Apyc ltée.La Cie Beaugeste ltée.La Cie d'asphalte J.Harris Lauzon ltée.Chambly.1968 à/to 1972 incl.Drummondvillc.1968 à/to 1972 incl.Toronto.1968 à/to 1972 incl.Montreal.1967 à/to 1972 incl.Mont-Joli.1964 à/to 1972 incl.Montréal.1969 à/to 1972 incl.Laval.1966 à/to 1972 incl.Côte St-Luc.1968 à/to 1972 incl.Montréal.1967 à/to 1972 incl.Ste-Agathe.1961 à/to 1972 incl.Montréal.1964 à/to 1972 incl.Montréal.1965 à/to 1972 incl.Montréal.1964 à/to 1972 incl.Lachine.1964 à/to 1972 incl.Charlesbourg.1968 à/to 1972 incl.St-Joseph-du-Lac.1965 à/to 1972 incl.La Cie d'entretien Laurentidc ltée.Repentigny.1965 à/to 1972 incl.La Cie d'habitation Roland inc.Neufchatel.1967 à/to 1972 incl.La Cie d'imperméabilisation de Québec ltée.Rimouski.1958 à/to 1972 incl.La Cie du Domaine Belgo-Québcc.St-François.1964 à/to 1972 incl.La Cie Georges Cauchon ltée.Québec.1965, 1966, 1968 à/to 1972 inc.La Cie Revetex de Québec inc.Montréal.1964 à/to 1972 incl.La Cie Swatson-Livet Ltd.Ste-Foy.1905 à/to 1972 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' annfe.U, 2041 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of the company Address Returns not filed La Compagnie Douville inc.Montréal.1964 à/to 1972 incl.La Compagnie Lyrique métropolitaine inc.Montréal.1967 à to 1972 incl.The Condominium Corporation.Montreal.1964 à/to 1972 incl.La Coupole des Gastronomes inc.Montréal.1968 à/to 1972 incl.La Cour à bois et scierie Perkins ltée.Perkins.1966 à/to 1972 incl.The Country Inn Inc.Terrebonne.1963 à/to 1972 incl.Grégoire Dandurand inc.Montréal.1967 à/to 1972 incl.La Discothèque Mont Ste-Anne inc.Ste-Marie Beauce.1966 à/to 1972 incl.Fontaine ltée.Québec.1960 à/to 1972 incl.Fortin Appliance Service Inc.St-François.1963 à/to 1972 incl.Foster Sand and Gravel Ltd.Foster.1963 à/to 1972 incl.Fount Inc.Montreal.1967 à/to 1972 incl.Four Seasons Mobile Home Ltd.Montreal.1961 à to 1972 incl.Franchine Equipment Service Inc.Montreal.1965 à/to 1972 incl.Francis Development Corp.Montreal.1964 à/to 1972 incl.Frank-N-Stein Franchises Ltd.Montreal.1971 Frontenac Billard inc.Montréal.1962 à/to 1965, 1967 à-to 1972 incl.G.& R.Realties Inc.Montreal.1967 à/to 1972 incl.G.& G.Lingerie inc.St-Janvicr.1966 à/to 1972 incl.G.& L.Sport Wear Inc.Ville D'Anjou.1968 à/to 1972 incl.G-Co limitée.St-Marc Carrières.1965 à/to 1972 incl.Gabtony construction ltée.St-Léonard.1968 à/to 1972 incl.Gagnon automobile (Magog) limitée.Magog.1965 à/to 1972 incl.La Galerie du siècle inc.Montréal.1968 à/to 1972 incl.Galica incorporée.Mount-Royal.1965 à/to 1972 incl.Garage Himbcault ltée.Valleyfield.1965 à/to 1972 incl.Garage Lucien Amyot inc.Valleyfield.1968 à/to 1972 incl.Garage St-Adolphe inc.Montréal.1968 à/to 1972 incl.Garage St-Jean (1964) inc.Québec.1964 à/to 1972 incl.Gascony Investments Ltd.Montreal.1965 à/to 1972 incl.Gasslnc.Montreal.1966 à/to 1972 incl.Gem Taxi Corp.Montreal.1965 à/to 1972 incl.Geralco Investment Inc.Montreal.1967 à/to 1972 incl.Gérald Investment Corp.Montreal.1963 à/to 1972 incl. 2012 QUÉBEC oil-HIM.GAZETTE, April 7, 1978, Vol.m.So.U Nom de lu compagnie Name of the company Adresse .Uldress Rapports non produits Returns not filed Gcri's Inc.( ierjac Inc.Gestion Talleyrand inc.Gcva ('orp.I.Id.(lino Liberia Landscaping Inc.( iino Restau ran I liée.Henri Giroux inc.( i lamour Services Ltd.Gleiirac Realties Limited.Go-Karl City Inc.Godar Construction Inc.Godbout ét associés inc.Goldor Inc.tiolfuay Corporation.(ioodies Products of Canada Inc.Gourmet ( 'artiervillc inc.(irallie Production Services Ltd.Grand Prix Model Raceways Ltd.The Great Montreal Press Inc.lean-Paul Grondin ltée.Grosvcnor Development Inc.Gucrcllc Service Station Inc.Guests & Events Identification Lid.Guild Industries Lui.ILM.Electronic lue.Habitant Gas & Oil Limited.Hairco Corporation.Halcarltée.Halden Property Management Ltd.Hamoniaiix & Mélanger inc.Hargold Cleaners I,til.Harrison Industries Co.Ltd.Helen's Hotels-Motels Inc.Ilelene Originals Inc.Montreal.19(17 à, to 1972 incl.Ste-Adèle.1966 à/to 1972 incl.St-Bruno.1964 à/to 1972 incl.Montreal.1965 à, to 1972 incl.Montreal.1969 à/to 1972 incl.Montréal.1965 à/to 1972 incl.Montréal.1963 à/to 1972 incl.Montreal.1969 à, to 1972 incl.Montreal.1961 à/to 1972 incl.Montreal.1963 à/to 1972 incl.Montreal.1967 à/to 1972 incl.St-Léoi.ard.1968 à/to 1972 incl.Montreal.1967 à/to 1972 incl.Montreal.1963 à/to 1972 incl.V.St-Laureiit.1966 à/to 1972 incl.Montréal.1965 à/to 1972 incl.Montreal.1963 à/to 1972 incl.Montreal.1965 à/to 1972 incl.Montreal.1966 à/to 1972 incl.Montréal.1961 à/to 1972 incl.Montreal.1964 à/to 1972 incl.Longueuil.1966 à/to 1972 incl.Montreal.1967 à/to 1972 incl.Montreal.1967 à/to 1972 incl.île Bizard.1966 à/to 1972 incl.Montreal.1965 à/to 1972 incl.Gatineau.1967 à/to 1972 incl.Montréal.1965 à/to 1972 incl.Montreal.1963 à/to 1972 incl.Cap-Rouge.1965 à/to 1972 incl.Montreal.1963 à/to 1972 incl.Duvernay.1963 à/to 1972 incl.Québec.1962 à/to 1972 incl.Montreal.1964 à/to 1972 incl. GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC, 7 avril 107.1.105' année, n\" I.', 2043 N'uni «le la compagnie Adresse Rapports non produits Saint- ierative association.The head office of this cooperative association is located in St.Félicien, Québec, in the Electoral District of Robcrval.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, 51296 Companies and Cooperatives.Coopérative étudiante de l'École secondaire Emile-Nclligan (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the \"Coopérative étudiante de i'École secondaire Émile-Nclligan », a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Montreal, Québec, in the Electoral District of Mercier.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, 51297 Companies and Cooperatives.Cooperative étudiante du Séminaire Saint-François de Cap-Rouge (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of the \"Coo|>érativc étudiante du Séminaire Saint-François de Cap-Rouge\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in St.Augustin, Québec, in the Electoral District of Portneuf.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, 51298 Companies and Cooperatives.Magasin co-op de Montmorency (Cooperative Associates Act) Notice is given that \"Magasin co-op de Montmorency\" was dissolved on March 20, 1973, in conformity with the provisions of the Cooperative Associations Act and the Winding-Up Act.Fernand Lalonde, Depidy Minister of Financial Institutions, 51212 Companies and Cooperatives. 2058 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.14 Commission des Transports du Québec La Commission des transports du Québec donne avis, conformément à l'article 46 de la Loi des Transports, des demandes suivantes: Requérante Nature de la requête AUTOBUS Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380 rue Barré, Montréal #102, P.Q.Dossier #602-A Bulletin 3-23-58 Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380 rue Barré, Montréal #102, P.Q.Dossier #602-A Bulletin 2-23-86 Rôle Mtl 3451 La requérante qui opère divers services en vertu de son permis demande l'autorisation de donner les services suivants: Service d'Autobus.Service No 1 : Transport de skieurs originant du Centre d'Achats Fairview (Pointe Claire) - du Centre d'Achats Dorval (Dorval) et du Centre d'Achats Rockland (Outremont) à destination du Mont Gabriel Lodge et de l'Hôtel Chanteelerc, et retour.Service No 2 : Transport de skieurs originant de l'Hôtel Mt-Royal (Montréal) de l'île des Soeurs (Verdun) et du Centre d'Achats Rockland (Outremont) à destination du Mont Gabriel Lodge et de l'Hôtel Chanteelerc.Parcours à suivre: Service No 1 : Côte de Liesse - Boul.Métropolitain et Autoroute des Lauren-tides - Service No 2 : Rues Peel - Sherbrooke - Université - Autoroute Bonaventure -Boul.Décarie - Boul.Métropolitain et Autoroute des Lauren-tides.Conditions et restrictions: 1.Ces services seront donnés cinq (5) jours par semaine du lundi au vendredi inclusivement.2.Les billets vendus seront pour des tours forfaitaires comprenant le transport et l'utilisation des facilités pour le ski du Mont Gabriel Lodge et de l'Hôtel Chanteelerc.3.Aucun service local ne sera donné dans et entre les municipalités sus-décri-tes.4.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.En remplacement de la requête publiée et inscrite pour audition sous le numéro 3461, en date du 16 décembre 1971.La requérante qui détient de la Régie, le permis suivant: Service d'Autobus et limousine - saisonnier - vendredis - samedis et dimanches - Transport de passagers de l'Aéroport International de Montréal à destination des Hôtels suivants situés dans les Laurentides, et retour - Mont Gabriel Lodge - Le Chanteelerc - Alpine Inn - Laurentide Inn - Gray Rocks Inn -Manoir Pinoteau - Mont Tremblant Lodge - Conditions et restrictions: 1.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance Générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.2.Ce service est saisonnier et ne sera donné que durant l'hiver les vendredis -samedis et dimanches de chaque semaine durant la période de ski entre le 15 décembre et le 15 avril de cliaque année ou selon toute modification acceptable par la Régie. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105- année, n° Il 2059 Québec Transport Commission In conformity with section 46 of the Transport Act, the Québec Transport Commission gives notice of the following requests: Applicant BUS Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380 Barré Street, Montreal #102, P.Q.File #602-A Bulletin 3-23-58 Service de Limousine, Murray Hill Ltée, 1380 Barré Street, Montreal #102, P.Q.File #602-A Bulletin 2-23-86 Nature of the request Roll Mtl 3451 The applicant, which operates various services pursuant to its permit, requests authorization to provide the following services: Bus Service.Service No.1 : Round trip from the Fairview Shopping Centre (Pointe-Claire), from the Dorval Shopping Centre (Dorval) and from the Rockland Shopping Centre (Outremont), to Mont-Gabriel Lodge and to the Hôtel Chanteelerc, and for the transportation of skiers.Service No.2: Transportation of skiers from the Hôtel Mont-Royal (Montreal), Ile-des-Soeurs (Verdun) and the Rockland Shopping Centre (Outremont) to Mont-Gabriel Lodge and the Hôtel Chante-clerc.Route followed: Service No.1 : Côte de Liesse - Métropolitain Boulevard and the Laurentian Autoroute - Service No.2: Pcel - Sherbrooke - University Streets - Bona venture Autoroute - Décarie Boulevard - Metropolitan Boulevard and the Laurentian Autoroute.Conditions and restrictions: 1.These services shall be provided five (5) days a week from Monday to Friday inclusive.2.Tickets sold will l>e for package tours including transportation and the use of the skiing facilities of Mont-Gabriel Lodge and of Hôtel Chanteelerc.3.No local service will l>e provided in and between the aforesaid municipalities.4.This permit docs not confer any of the privileges granted by General Order No.17 of the Transportation Board, respecting special or charter trips.In lieu of the request dated December 16, 1971, published and registered for hearing under number 31,51.The applicant holds the following permit granted by the Board: Bus and limousine service - seasonal - Fridays - Saturdays and Sundays -Transportation of passengers from the Montreal International Airport to the following Hotels located in the Laurentides - Mont Gabriel Lodge - Le Chanteelerc - Alpine Inn - Laurcntide Inn - Gray Rocks Inn - Manoir Pinoteau -Mont Tremblant Ix>dge: round trip.Conditions and restrictions: 1.This permit does not confer any of the privileges granted by General Order No.17 respecting special or charter trips.2.This service is seasonal and shall be given in winter only, on Fridays-Saturdays and Sundays of each week during the skiing season, from December 15th to April 15th of each year, and according to any amendment deemed acceptable by the Board. 20(50 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.1A Riverside Bus Service Reg'd, (M.Emile Viens opérant sons le nom de:) CP.56, Farnham, Cté Missisquoi, P.Q.Dossier #2492-A Bulletin 2-19-52 Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380, rue Barré, Montréal 102, P.Q.Dossier #602-A Bulletin 2-26-62 Robert Robillard, 271, rue Cedar, Gatineau, Cté Hull, P.Q.Dossier #3363-A Bulletin 3-4-59 Guy Bellerive, 3, rue St-.Iacques, Ste-Agathe des Monts, Cté Terrebonne, P.Q.3.Ce service doit être donné directement de l'Aéroport aux Hôtels sus-men-tionnés, et retour, sans droit de transfert de passagers, excepte de et au service aérien à l'Aéroport.Demande à la Régie que son permis soit modifié de la façon suivante: 1.enlever de son permis actuel l'Hôtel Laurentide Inn.incendié.2.être autorisée à transporter des passagers de l'Aéroport International de Dorval à destination de Ste-Agathe, et retour.Ce service sera saisonnier durant l'hiver les vendredis - samedis - et dimanches de chaque semaine durant la saison de ski entre le 15 décembre et le 15 avril de chaque année.Conditions et restrictions: 1.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance Générale No.17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie originant de Ste-Agathe.2.Pas de service local entre l'Aéroport de Dorval et Ste-Agathe.Rôle Mtl 3474 Le requérant détenteur d'un permis de la Régie qui l'autorise, entre autres, à donner le service suivant: Service d'Autobus Transport de passagers à l'occasion de voyages à charte-partie dans et entre les municipalités suivantes: L'Ange Gardien - St-Césaire - Rougemont - Ste-Sabine - St-Ignace de Farnham.Condition et restriction: 1.Ce service est réservé aux membres et joueurs de tous les comités de loisirs des endroits ci-haut mentionnés et ne comporte aucun autre droit prescrit à l'Ordonnance Générale No.17 de la Régie.Demande à la Régie une modification pour être autorisé à l'avenir à donner le service suivant: Service d'autobus Transport de passagers à l'occasion de voyages à charte-partie originant des comtés de Rouville et Missisquoi et des municipalités de St-Grégoire - Ste-Bri-gide à tout point situé dans la province de Québec dans un rayon de 200 milles des comtés et municipalités sus-mentionnées.Condition et restriction: 1.Ce service est réservé aux membres et joueurs de tous les comtés des loisirs des endroits sus-mentionnés.Rôle Mtl 3534 La requérante demande à la Régie d'être autorisée à donner le service suivant: Service d'Autobus Transport de skieurs à l'occasion de voyages à charte-partie originant de tout point situé sur l'Ile de Montréal, à destination de tout centre de ski situé dans la province de Québec, et retour.Rôle Mtl 3610 Le requérant demande à la Régie l'autorisation de donner le service suivant: Service d'Autobus Transport de passagers, à l'occasion de voyages à charte-partie de Gatineau, Perkins, Templeton, Lac McGregor, St-Pierre de Wakefield à destination de tout point situé dans la province de Québec et dans un rayon de 100 milles desdites municipalités, et retour.Rôle Mtl 3627 Le requérant demande à la Régie l'autorisation de donner le service suivant: Service d'Autobus Transport de passagers, à l'occasion de voyages à charte-partie dans les limites de la ville de Ste-Agathe et de Ste-Agathe à destination de tout point situé dans GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° 1 2061 Riverside Bus Service Reg'd, (Mr.Emile Viens operating under the name of :) P.O.Box 56, Farnham, County of Missisquoi, P.Q.File #2492-A Bulletin 2-19-52 Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380 Barré Street, Montreal 102, P.Q.File #602-A Bulletin 2-26-62 Robert Robillard, 271 Cedar Street, Gatineau, County of Hull, P.Q.File #3363-A Bulletin 3-4-59 Guy Bellerive, 3 St.Jacques Street, Ste.Agathc-des-Monts, County of Terrebonne, P.Q.3.This service must be provided directly from the Airport to the aforesaid Hotels, return, without the right to transfer passengers, except from and ¦ to the air service at the Airport.Requests the Board to amend its permit as follows: 1.to delete from its present permit Laurcntide Inn, which burnt down.2.to authorize the applicant to transport passengers from the Dorval International Airport to Ste.Agathe and return.This service will be seasonal for the winter on Friday, Saturday, and Sunday of each week during the ski season, between December 15th and April 15th of each year.Conditions and restrictions: 1.This permit does not grant any of the privileges of General Ordinance No.17 respecting special or charter trips from Ste.Agathe.2.No local service between Dorval Airport and Ste.Agathe.Roll Mtl 3474 The applicant, holds a permit from the Board authorizing him, among other things, to provide the following service: Bus service Transportation of passengers for charter trips in and between the following municipalities: L'Ange Gardien - St.Césaire - Rougcmont - Ste.Sabine - St.Ignace and Farnham.Condition and restriction: 1.This service applies to the members of all recreation committees, the players, from the localities hereinabove mentioned; it does not include any other right prescribed in General Ordinance No.17 of the Board.Requests the Board for a modification authorizing from now on the following service: Bus service Transportation of passengers on charter trips originating from the counties of Rouville and Missisquoi; and from the municipalities of St.Grégoire \u2014 Ste, Brigide towards any point located in the Province of Québec within a radius of 200 miles from the counties and municipalities hereinabove mentioned.Condition and restriction: 1.This service applies to the members of all the recreation committees, their players, located in the above mentioned places.Roll Mtl 3534 The applicant requests the Board's permission to provide the following service: Bus service Transportation of skiers on charter trips from any point located on the Island of Montreal to any ski centre located in the Province of Québec, and return.Roll Mtl 3610 The applicant request the Board's permission to provide the following service: Bus service Transportation of passengers on charter trips from Gatineau, Perkins, Tera-pleton, McGregor Lake, St.Pierre de Wakefield to any point located in the Province of Québec and within a radius of 100 miles from the said municipalities and return.Roll Mtl 3627 The applicant requests the Board's permission to provide the following service: Bus service Transportation of passengers on charter trips within the limits of the Town of Ste.Agathe and from Ste.Agathe to any point located within the Province of 2062 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.11 Dossier #3364-A Bulletin 3-5-61 la province de Québec, et retour, pour le compte des loisirs de la ville de Ste-Agathe.Le coût du transport sera défrayé par la ville de Ste-Agathe des Monts ou par l'organisation municipale des loisirs.Conditions et restrictions: 1.Ce transport est restreint aux passagers transportés pour le compte de la ville de Ste-Agathe des Monts ou par l'organisation municipale des loisirs de Ste-Agathe.2.Le détenteur devra maintenir en vigueur, pour la protection du public transporté, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Générale No 5448 de la Régie des Transports, en date du 21 juin 1963.Salvatore Riviera, 2120, rue St-Zotique, Montréal, P.Q.Dossier #3373-ATL Paul-Émile Boissé, 708, rue Louise, Ixmgueuil, Cté Chambly, P.Q.Dossier #3367-ATL Bulletin 3-8-69 Rôle Mtl 3678 Le requérant demande à la Régie l'autorisation d'opérer les services suivants: a) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non renregistrés comme taxis), à l'occasion de mariages seulement dans Montréal et dans les municipalités comprises dans un rayon de 5 milles de ladite cité.b) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de mariages seulement dans Montréal et dans un rayon de 5 milles à destination des municipalités situées dans un rayon de 25 milles de ladite cité, et retour.Rôle Mtl 3721 Le requérant demande à la Régie l'autorisation de donner les services suivants: a) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles dans Montréal et dans les municipalités comprises dans un rayon de 15 milles de ladite cité.b) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles de Montréal ou des municipalités dans un rayon de 15 milles de ladite cité à un point situé dans la province ou aux frontières.Voyageur Colonial Ltée, 265 rue Albert, Ottawa, Ontario.Dossier #221-A Bulletin 3-9-56 Service de Limousine Murray Hill Ltée, 1380 rue Barré, Montréal #102, P.Q.Dossier #602-A Bulletin 3-10-67 Rôle Mtl 3745 La requérante qui détient un permis de la Régie l'autorisant à donner entre autre les services suivants: Service No 1 : De Grand Remous à la frontière Québec-Ontario (destination Ottawa), et retour.Service No 2: Hull à Maniwaki, et retour.Demande à la Régie que soit enlevée la restriction quant aux privilèges de l'Ordonnance Générale #17 concernant ces deux services.Elle demande également à la Régie l'autorisation d'effectuer des voyages spéciaux ou à charte-partie originant de Hull - Pointe Gatineau - Gatineau Mills -Templeton - Masson et Buckingham à tout endroit situé dans la province de Québec, et retour, sauf dans le territoire desservi par la Communauté Régionale de POutaouais.Rôle Mtl 3758 La requérante qui opère divers services en vertu du permis qu'elle détient de la Régie demande d'être autorisée entre autres, à donner un service d'excursions touristiques (sight-seeing tours) pour les clients de divers Motels situés sur la Rive Sud du St-Laurent demande d'être autorisée à ajouter à ce service le « Motel Holiday Inn » situé à 50 de la rue de la Seigneurie à Longueuil.Les conditions et restrictions seront les mêmes que celles de son présent permis. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1978, 105\" année, n° Il 2063 File #3364-A Bulletin 3-5-61 Salvatore Riviera 2120 St.Zotique Street, Montreal, P.Q.File #3373-ATL Paul-Emile Boisse, 708 Louise Street, Longueuil, County of Chambly, P.Q.File #3367-ATL Bulletin 3-8-69 Québec, and return, for the account of the recreational centre of the Town of Ste.Agathe.Transportation costs will be paid by the Town of Ste.Agathe-des-Monts or by the municipal recreation authorities.Conditions and restrictions: 1.This transportation is restricted to passengers travelling for the account of the Town of Ste.Agathe-des-Monts or by the municipal recreation authorities of Ste.Agathe.2.The holder must, for the protection of the travellers, maintain a public liability insurance policy, in conformity with the provisions of General Ordinance No.5448 of the Transport Board, dated June 21, 1963.Roll Mil 3678 The applicant requests the Board's permission to provide the following services: (a) Transportation of passengers by family cars (not registered as taxis), for weddings only, in Montreal and in the municipalities included within a radius of 5 miles from said City.(i) Transportation of passengers, by family.(b) cars (not registered as taxis), for weddings only, in Montreal and within a radius of 5 miles to municipalities located within a radius of 25 miles from the said City and return.Roll Mtl 3721 The applicant requests the Boards' permission to provide the following services: (a) Transportation of passengers, by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals, to carry flowers, in Montreal and in the municipalities included within a radius of 15 miles from said City.(b) Transportation of passengers, by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals and to carry flowers, from Montreal or from municipalities within a radius of 15 miles from said City to a point located in the Province or at the borders.Voyageur Colonial Ltée, 265 Albert Street, Ottawa, Ontario.File #221 -A Bulletin 3-9-56 Roll Mtl 3745 The applicant holds a permit from the Board authorizing him to provide, among other things, the following services: Service No.1 : From Grand Remous to the Québec-Ontario border (destination Ottawa), and return.Service No.2: Hull to Maniwaki and return.Requests that the Board remove the restriction related to the privileges of General Ordinance #17 respecting these two services.The applicant also requests the Board's permission to carry out special or charter trips from Hull - Pointe-Gatineau - Gatineau Mills - Templeton -Masson and Buckingham to any locality situated in the Province of Québec, and return, except in the territory served by the Regional Community of the Ottawa Valley.Limousine Service Murray Hill Ltée, 1380 Barré Street, Montreal #102, P.Q.File #602-A Bulletin 3-10-67 Roll Mtl 3758 The applicant who provides various services in conformity with its permit from the Board requests the authorization, among other things, to provide sightseeing tours for the customers of various motels located on the south shore of the St.Lawrence together with the permission to add to this service the \"Holiday Inn Motel\" located at 50 Seigneurie Street, in Longueuil.The conditions and restrictions will be the same as those of its present permit. 2064 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.li Mme Huguetie Leboeuf, 6435, rue Louis Dupire, Montréal #431, P.Q.Dossier #2186-A Bulletin 3-10-69 Voyageur Colonial Ltée, 265, rue Albert, Ottawa, Ontario.Dossier #221-A Bulletin 3-14-54 Commission Scolaire, Outaouais-Hull, Commission Scolaire Régionale de l'Outaouais, Commission Scolaire d'Aylmer, Requérantes, vs La Commission de Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais, 54, rue Front, Hull, Cté Hull, P.Q.Intimée, Dossier #3415-A M.Donald David Murison, 382-B, Lac Rhéaume, Perkins sur le Lac, Hull, P.Q.Dossier #3384-A Bulletin 3-15-52 Rôle Mtl 3759 La requérante qui détient de la Régie un permis l'autorisant à effectuer le transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans à différentes écoles maternelle demande l'autorisation de donner Je service suivant: Service d'Autobus.Transport d'étudiants de treize (13) à dix-sept (17) ans, à l'occasion de voyages à charte-partie: 1) d'un point à un autre dans les limites de la ville de Montréal - 2) occasionnellement de Montréal à l'Aéroport International de Montréal situé à Dorval, et retour.Conditions et restrictions: 1.Ce transport doit être effectué par contrat avec le Haut Commissariat de la Jeunesse des loisirs et des Sports (Ministère de l'Éducation) de la province de Québec conjointement avec le Gouvernement Fédéral.2.Ce service ne sera donné que durant la saison estivale 1973.3.La détentrice ne pourra se prévaloir des privilèges conférés par l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports, concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Rôle Mtl 3860 La requérante qui détient un permis de la Régie l'autorisant, entre autres, à effectuer le transport de passagers entre Montréal et la frontière de l'Ontario, à destination de différents points dans cette dernière province demande à la Régie d'être autorisée à donner un service entre les municipalités qu'elle dessert en Ontario et l'Aéroport International de Ste-Scholastique.Conditions et restrictions: 1.Aucun passager ne sera transporté entre Montréal et l'Aéroport International de Ste-Scholastique.2.La détentrice ne pourra se prévaloir des privilèges de l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports, concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Rôle Mtl 3886 Les requérantes se sont adressées à la Régie dans le but de contester les tarifs déposés par l'Intimée pour le transport des écoliers pour l'année 1972-1973.Rôle Mtl 3905 Le requérant demande l'autorisation de donner par autobus, le service suivant: Service d'Autobus De Perkins sur le Lac (Lac Bataille et Lac Rhéaume) - Barnes Lake - Mud Lake - McGregor Lake - Baie Courville - Perkins - Jeanne-d'Arc - aux frontières Québec-Ontario destination Ottawa, et retour.Parcours à suivre: Route #366 et #8.Conditions et restrictions: 1.Ce voyage sera donné du lundi au vendredi inclusivement durant la saison estivale et les fins de semaine durant la saison hivernale seulement.2.Pas de service local entre Ste-Rose-de-Lima et Ottawa, ces deux endroits inclus. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° IL 2065 Mrs.Huguette Leboeuf, 6435 Louis-Dupire Street, Montreal #431, P.Q.File #2186-A Bulletin 3-10-69 Voyageur Colonial Ltée, 265 Albert Street, Ottawa, Ontario.File #221-A Bulletin 3-14-54 The Outaouais-Hull School Board, The Outaouais Regional School Board, Aylmer School Board, petitioners, vs The Outaouais Regional Community Transit Commission, 54 Front Street, Hull, County of Hull, P.Q., defendant.File #3415-A Mr.Donald David Murison, 382-B, Lac Rhéaume, Perkins sur le Lac, Hull, P.Q.File #3384-A Bulletin 3-15-52 Roll Mtl 3759 The applicant holding a permit from the Board which authorizes the transportation children of three (3) to seven (7) years of age to various kindergartens, requests permission to provide the following service: Bus service.Transportation of students of thirteen (13) to seventeen (17) years of age, on charter trips: (1) from one point to another within the limits of the City of Montreal.(2) occasionally from Montreal to the Montreal International Airport located in Dorval, and return.Conditions and restrictions: 1.This transportation must be made under contract with the High Com-missionership of Youth, Recreation and Sports (Department of Education) of the Province of Québec in conjunction with the Federal Government.2.This service will be provided only during the 1973 summer season.3.The holder will not be able to avail itself of the privileges granted by General Ordinance No.17 of the Transport Board, respecting special or charter trips.Roll Mtl 3860 The applicant holding a permit from the Board authorizing him, among other things, to carry passengers between Montreal and the Ontario border, to various points in the latter province, requests the Board's permission to provide a service between the municipalities it serves in Ontario and the International Airport of Ste.Scholastique.Conditions and restrictions: 1.No passenger will travel between Montreal and the International Airport of Ste.Scholastique.2.The holder will not be able to avail itself of the privileges of General Ordinance No.17 of the Transport Board, respecting special or charter trips.Roll Mtl 3886 The petitioners applied to the Board for the purpose of contesting the rates deposited by the defendant for the transportation of students for the year 1972-1973.Roll Mtl 3905 The applicant requests permission to provide the following service by bus: Bus service.From Perkins sur le Lac (Lac Bataille and Lac Rhéaume), Barnes Lake, Mud Lake, McGregor Lake, Baie Courville, Perkins and Jeanne-d'Arc to the Québec-Ontario borders (destination Ottawa), and return.Punîtes to follow: Route Nos.366 and 8.Conditions and restrictions: 1.This trip will be provided from Monday to Friday inclusive during the summer season; it will be provided on weekends during the winter season only.2.No local service between Ste.Rose-de-Lima and Ottawa; those two localities are included. 2066 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Cité de LaSalle, 13 avenue Strathyre Ave., Cité de LaSalle, P.Q.Dossier #2283 Ubald Aquin, 363, rue St-Régis, St-Roch de l'Achigan, Cté l'Assomption, P.Q.Dossier #3448-A Bulletin 3-21-65 Henri Bruneau Inc., 101 rue Dixon, Ville LaSalle, P.Q.Dossier #2389-A Bulletin 3-21-63 3.Le requérant devra maintenir en vigueur, pour la protection des passagers transportés, une assurance de responsabilités légales conformément aux dispositions de l'Ordonnance (ïénérale No.5448 de la Régie des Transports, en date du 21 juin 1963.4.Le requérant ne pourra se prévaloir des privilèges conférés par l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Rôle Mtl 4009 La Cité de LaSalle s'est adressée à la Régie pour l'approbation du règlement #1358 amendant le #1131 concernant les autos-taxis.Article No 1 : Le paragraphe d de l'article 25 du Règlement #1131 concernant les autos-taxis est amendé en ajoutant le sous paragraphe suivant: « Le conducteur peut exiger la somme de cinquante ($0.50) s'il doit, sur les instructions du voyageur, transporter à la main un ou plusieurs sacs ou boîtes.» Rôle Mtl 4044 Le requérant demande à la Régie l'autorisation de donner les services suivants: Service d'Autobus 1.Transport d'écoliers, à l'heure du midi seulement, résidant dans St-Roch de l'Achigan et fréquentant l'école polyvalente de St-Roch de l'Achigan, et retour.2.Transport d'étudiants, à l'occasion de voyages spéciaux et à charte-partie, originant de St-Roch de l'Achigan à tout endroit situé dans un rayon de cinquante (50) milles de ladite municipalité, et retour.Conditions et restrictions: Service No 1: 1.Ce service est réservé exclusivement au transport d'enfants, à l'heure du midi, de leur résidence située dans la municipalité de St-Roch de l'Achigan et se rendant à l'école polyvalente de St-Roch de l'Achigan, et retour.2.Le détenteur devra maintenir en vigueur, pour le bénéfice des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Générale No 5448 de la Régie des Transports, en date du 21 juin 1963.3.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports, concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Service No 2: 1.Ce service est réservé exclusivement au transport d'étudiants fréquentant les écoles Notre-Dame et la Polyvalente de St-Roch de l'Achigan de même que pour toutes activités sportives, récréatives et culturels de ces mêmes étudiants.Rôle Mtl 4045 La requérante qui opère divers services en vertu de son permis demande à la Régie l'autorisation de donner le service suivant: Service d'autobus De la gare Windsor à Montréal, à destination de l'Hôpital Militaire de Ste-Anne de Bellevue, et retour, pour le transport des vétérans et leur famille se rendant visiter des patients dudit hôpital, le dimanche de chaque semaine seulement.Parcours à suivre: Aller: Via Transcanadienne Retour: Boul.Métropolitain.Dans Montréal: D'après entente avec les autorités municipales. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" U 2067 3.The applicant must keep in force, for the protection of travelling passengers, public liability insurance policy in conformity with the provisions ot General Ordinance No.5448 of the Transport Board, dated June 21, 1963.4.The applicant will not be able to avail himself of the privileges granted by General Ordinance No.17 of the Transport Board respecting special or charter trips.City of LaSalle, 13 Strathyre Avenue, City of LaSalle, P.Q.File #2283 Roll Mtl 4009 The City of La Salle applied to the Board for approval of bylaw #1358 amending #1131 concerning auto-taxis.Article No.1 : Paragraph (d) of article 25 of bylaw #1131 respecting auto-taxis is amended by adding the following subparagraph: \"The driver may require the sum of fifty cents ($0.50) if he must, on the passenger's instruction, carry by hand one or several bags or boxes.\" Ubald Aquin, 363 St.Régis Street, St.Roch-de-l'Achigan, County of L'Assomption, P.Q.File #3448-A Bulletin 3-21-65 Roll Mtl 4044 The applicant requests the Board's permission to provide the following services: Bus service.1.Transportation of students (during the noon hour only) residing in St.Roch-de-l'Achigan and attending the St.Roch-de-l'Achigan Polyvalent School, and return.2.Transportation of students, for special and charter trips, originating from St.Roch-de-l'Achigan to any locality situated within a radius of fifty (50) miles from the said Municipality, and return.Conditions and restrictions: Service No.1:1.This service is reserved exclusively for the transportation of children, during the noon hour, from their residence located in the Municipality of St.Roch-de-l'Achigan to the St.Roch-de-l'Achigan Polyvalent School, and return.2.The holder must keep in force, for the benefit of the children carried, a public liability insurance policy, in conformity with the provisions of General Ordinance No.5448 of the Transport Board, dated June 21, 1963.3.This permit does not grant any of the privileges of General Ordinance No.17 of the Transport Board, respecting special or charter trips.Service No.2: 1.This service is exclusively reserved for the transportation of students attending Notre-Dame School and the St.Roch-de-l'Achigan Polyvalent School as well as for all sports, recreational and cultural activities of said students.Henri Bruneau Inc.101 Dixon Street, City of LaSalle, P.Q.File #2389-A Bulletin 3-21-63 Roll Mtl 4045 The holder who ojjerates various services in conformity with its permit requests the Board's permission to provide the following service: Bus service: From Windsor Station in Montreal to the Military Hospital of Ste.Anne-de-Bellevue, and return, for the transportation of veterans and their families visiting the patients of said hospital on Sunday of each week only.Routes to follow: Outward: Via the Trans-Canada Highway: Return: Metropolitan Boulevard.In Montreal: According to an agreement with municipal authorities. 2068 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.IL M.Léo Iloussin, 10,775 Avenue Oscar, Apt.#1, Montréal-Nord, P.Q.Req uéran t-vendeu r Dossier #1710-A N.D.G.School Bus Service, (M.Marc Resther opérant sous le nom de:) 6190 rue St-Jacques ouest, Montréal, P.Q.Requérant-acquéreur Dossier #1831-A Bulletin 3-21-62 Laurentian School & Camp Bus Reg'd., (Morris Torontour, agissant sous le nom de :) 555, Boulevard Laurentien, Pièce 103 St-Laurent, Montréal 379, P.Q.Dossier #3046-A Bulletin 3-21-64 Conditions et restrictions: 1.Ce service est restreint au transport de vétérans et leur famille et se rendant visiter les patients à l'Hôpital Militaire de Ste-Anne de Bellevue.2.Ce service sera donné le dimanche de chaque semaine seulement.3.Le coût du transport sera défrayé par la Légion Canadienne.4.La requérante ne pourra se prévaloir des privilèges conférés par l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports, concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Rôle Mtl.4046 Le requérant vendeur qui détient de la Régie un permis l'autorisant à donner les services suivants: Service d'autobus.Service No 1 : Voyages spéciaux ou à charte-partie de l'École Stc-Hélènc située à 9469 ouest, boul.Gouin, Pierrefonds, P.Q., au Lac des Pins, et retour, pour le transport des enfants fréquentant la susdite école.Service No 2: Transport d'enfants résidant à Montréal et fréquentant La Clinique d'Été de la Faculté de Chirurgie et l'Université de Montréal.Condition et restriction: 1.Les privilèges accordés ci-dessus sont restrictifs et ne confèrent aucun autre droit prévu par l'Ordonnance Générale No 17 de la Régie des Transports.Demande l'autorisation de vendre ses services au requérant acquéreur N.D.G.School Bus Service, (M.Marc Resther, opérant sous le nom de:).Rôle Mtl.4050 La requérante qui effectue un service de transport d'enfants âgés de trois (3) à sept (7) ans, Demande à la Régie de fournir le service suivant: Service d'autobus Transporter, par autobus, des passagers et leur bagage de l'Aéroport International de Montréal, à Dorval, aux hôtels de la région Laurentienne, aller et retour : \u2014 Mont-Habitant, St-Sauveur-dcs-Monts; \u2014 Mont-Gabriel, Mont-Gabriel; \u2014 Le Totem Motel, Piedmont; \u2014 Nicky's Cascades, Mont-Rolland; \u2014 Le Chanteelerc, Ste-Adèle; \u2014 Alpine lnn, Ste-Marguerite; \u2014 Hôtel Esterel, Ville d'Estercl; \u2014 Sun Valley, Hôtel Suisse, Ste-Adèle \u2014 Parker's Lodge, Lac Faquin (Val David); \u2014 Far Hills Inn, Val-Morin; \u2014 La Sapinière, Val-David; \u2014 Laurcntide Chalet Suisse, Ste-Agathe; \u2014 La Réserve, St-Donat; \u2014 Grey Rocks lnn, St-Jovite; \u2014 Villa Bellevue, St-.Jovitc; \u2014 Cuttle's Tremblant Club, Mont-Tremblant; \u2014 Manoir Pinoteau, Mont-Tremblant; \u2014 Mont-Tremblant Lodge, Mont-Tremblant; Parcours à suivre: L'autoroute et/ou la voie No 11 Conditions et restrictions a) Ce permis n'autorise aucun service sous l'ordonnance No 17.b) Le service sera saisonnier, comprenant un service d'hiver les samedis et dimanches de chaque semaine durant la saison du ski, en vigueur jusqu'au 15 avril de chaque année, ou toute modification d'icelui acceptable par la Régie. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" 1A 2069 Mr.Léo Roussin, 10,775 Oscar Avenue, Apt.#1, Montreal-North, P.Q., applicant-vendor File f 1710-A and N.D.G.School Bus Service, (Mr.Marc Resther operating under the name of :) 6190 St.James Street West, Montreal, P.Q., applicant-purchaser File #1831-A Bulletin 3-21-62 Laurentian School & Camp Bus Reg'd, (Morris Torontour, operating under the name of :) 555 Laurentian Boulevard, Room 103, St.Laurent, Mtl.379, P.Q.File #3046-A Bulletin 3-21-64 Conditions and restrictions: 1.Tliis service is restricted to the transport of veterans and the families visiting the patients at the Military Hospital of Ste.Anne-de-Bel le vue.2.This service will be provided on the Sunday of each week only.3.The cost of transportation will be paid by the Canadian Legion.4.The applicant will not be able to avail itself of the privileges granted by General Ordinance No.17 of the Transport Board, respecting special or charter trips.Roll Mtl 4046 The applicant-vendor who holds a permit issued by the Board authorizing him to provide the following services; Bus service.Service No.1 : Special or charter trips from the Ste.Hélène School located at 9469 Gouin Boulevard West, Pierrefonds, P.Q., to Lac des Pins, and return, for the transportation of the children attending said School.Service No.2: Transportation of children residing in Montreal and attending La Clinique d'Été de la Faculté de Chirurgie de l'Université de Montréal.Condition and restriction: 1.The privileges granted hereinabove are restrictive and do not grant any other right provided for by General Ordinance No.17 of the Transport Board.Requests the permission to sell its services to the applicant purchaser: N.D.G.School Bus Service, (Mr.Marc Resther, operating under the name of:).Roll Mtl 4050 The applicant who operates a service for the transportation of children between three (3) and seven (7) years of age is asking the Board to operate the following service: Autobus service To transport, by autobus, passengers and their baggage, from Montreal International Airport in Dorval to the following Laurentian resort hotels, and return: - Mont Habitant, St.Sauveur des Monts; - Mont Gabriel, Mont Gabriel; - Le Totem Motel, Piedmont; - Nicky's Cascades, Mont Rolland; - Le Chanteelerc, Ste.Adèle; - Alpine lnn, Ste.Marguerite; - Hotel Esterai, Town of Estercl; - Sun Valley Hotel Suisse, Ste.Adèle; - Parker's Lodge, Lac Paquin (Val David) ; - Far Hills lnn, Val Morin; - La Sapinière, Val David; - Laurcntide Chalet Suisse, Ste.Agathe; - La Réserve, St.Donat; - Gray Rocks lnn.St.Jovite; - Villa Bellevue, St.Jovite; - Cuttle's Tremblant Club, Mont-Tremblant; - Manoir Pinoteau, Mont-Tremblant; - Mont-Tremblant Lodge, Mont-Tremblant; Route to be followed: Auto route or / and route No.11.Conditions and restrictions: (a) This permit shall not authorize any service under Ordinance No.17.(6) The service shall be seasonal, covering a winter service on Saturday and Sunday of each week during the ski season, valid until April 15th of each year or any modification thereof acceptable to the Board. 2070 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.11 Voyages Escapades, (M.J.H.G.Boulanger opérant sous le nom de :) 119, rue Frontenac, Sherbrooke, Cté Sherbrooke, P.Q.Dossier #3440-A Bulletin 3-21-69 Oscar Casgrain, 3428, rue Bordeaux, Montréal, P.Q.Dossier #2847-ATL Les Autobus de la Rive Sud Ltée, 120, Place d'Youville, Nicolet, P.Q.Dossier #691-A Bulletin 3-22-54 Arthur J.Rochette, 126, rue Dieppe, Pointe Claire, P.Q.Dossier #3403-A & ATL c) Le service s'effectuera en ligne directe de l'Aéroport International de Montréal, à Dorval jusqu'aux hôtels, et retour, excluant toute autorisation de transférer des passagers, si ce n'est à l'entrée et à la sortie des services aériens à l'Aéroport.Rôle Mtl.4062 Le requérant demande à la Régie l'autorisation d'agir comme courtier en transport pour des voyages originant de Sherbrooke - Victoriaville - Drummondville - East Angus et Magog à destination de tout point situé au Canada, aux États-Unis et au Mexique.Rôle Mtl.4071 Le requérant demande à la Régie l'autorisation de donner les services suivants: o) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles dans Montréal et dans les municipalités comprises dans un rayon de 15 milles.b) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles de Montréal ou des municipalités dans un rayon de 15 milles de ladite cité à un point situé dans la province ou aux frontières.Rôle Mtl.4072 La requérante qui détient de la Régie le service suivant: Service d'autobus De Ste-Françoise Romaine à Québec, et retour.Demande à la Régie de donner de façon permanente le service suivant: De Ste-Françoise Romaine (sur appel téléphonique) à Québec, et retour, via Fortierville, Parisville, Deschaillons, Leclercville, Lotbinière, Ste-Croix, St-Antoine, St-Nicolas et Pont de Québec.Parcours à suivre: Route régionale: De Ste-Françoise Romaine et Deschaillons.Route No 3: De Deschaillons à Québec.Conditions et restrictions: 1. ou de Ste-Françoise Romaine (sur appel téléphonique).2.Pas de service local entre Fortierville, Parisville et Deschaillons, ces trois (3) endroits inclus.3.Pas de service local entre le Pont de Québec et Québec.Elle demande également de prolonger jusqu'à décision finale l'autorisation temporaire accordée par Ordonnance, en date du 13 octobre 1972 et expirant le 30 novembre 1972.La requérante suggère que la restriction « portes fermées entre Deschaillons et Québec » soit remplacée par une restriction « pas de service local entre Fortierville et Deschaillons.Rôle Mtl.4075 Le requérant demande à la Régie l'autorisation d'opérer les services suivants: a) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles dans Pointe-Claire et dans les municipalités comprises dans un rayon de 15 milles de ladite cité.6) Transport de passagers, par véhicules de promenade (non enregistrés comme taxis), à l'occasion de baptêmes, mariages et funérailles et de fleurs, à l'occasion de funérailles de Pointe Claire ou des municipalités dans un rayon de 15 milles de ladite cité à un point situé dans la province ou aux frontières. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n\" IL 2071 Voyages Escapades, (Mr.J.H.G.Boulanger operating under the name of:) 119 Frontenac Street, Sherbrooke, County of Sherbrooke, P.Q.File #3440-A Bulletin 3-21-69 Oscar Casgrain, 3428 Bordeaux Street, Montreal, P.Q.File #2847-ATL Les Autobus de la Rive Sud Ltée, 120 Place d'Youville, Ni'colet, P.Q.File 691-A Bulletin 3-22-54 Arthur J.Rochette, 126 Dieppe Street, Pointe Claire, P.Q.File #3403-A & ATL (c) The service shall l>e a direct line from the Montreal International Airport in Dorval to the hotels, and return, without any right to transfer passengers except to and from the airlines services at the Airport.Roll Mtl 4062 The applicant requests the Board's permission to act as a transport broker for trips leaving from Sherbrooke - Victoriaville \u2014 Drummondville - East Angus and Magog, for any point situated in Canada, in the United States and in Mexico.Roll Mtl 4071 The applicant requests the Board's permission to give the following services: (a) Transportation of passengers, by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals and for the carrying of flowers for funerals in Montreal and in the municipalities located within a radius of 15 miles.(6) Transportation of passengers, by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals and for carrying flowers for funerals in Montreal or the municipalities located within a radius of 15 miles from said City to a point located in the Province or at the borders.Roll Mtl 4072 The applicant holds a permit from the Board for the following service: Bus service.From Ste.Françoise-Romaine to Québec City, and return.Requests the Board's permission to provide the following service in a permanent way: From Ste.Françoise-Romaine (upoii phone call) to Québec City, and return, via Fortierville, Parisville, Deschaillons, Leclercville, Lotbinière, Ste.Croix, St.Antoine, St.Nicolas and the Québec Bridge.Roules to follow: Regional Route: From Ste.Françoise-Romaine and Deschaillons.Route 3: From Deschaillons to Québec City.Conditions and restrictions: 1.At or from Ste.Françoise-Romaine (upon phone call).2.No local service between Fortierville, Parisville and Deschaillons, the latter three (3) localities included.3.No local service between the Québec Bridge and Québec City.It also requests that the temporary authorization granted by an Ordinance, dated October 13,1972, and expiring November 20, 1972, be extended up to the final decision.The applicant suggests that the restriction \"closed doors between Deschaillons and Québec City\" be replaced by a restriction \"no local service between Fortierville and Deschaillons.Roll Mtl 4075 The applicant requests the Board's permission to operate the following services: (a) Transportation of passengers by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals and the carrying of flowers for funerals from Pointe-Ciaire or the municipalities located within a radius of 15 miles from said City.(b) Transportation of passengers by family cars (not registered as taxis), on the occasion of baptisms, weddings, funerals and the carrying of flowers for funerals from Pointe Claire or the municipalities located within a radius of 15 miles from said City at a point located in the Province or at the borders. 2072 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.IL LOCATION Train Trailer Rentals Ltd., a/s Me Adrien R.Paquette, 200, St-Jacques ouest, suite 900, Montréal 126, P.Q.Siège social: P.O.Box 84 Don Mills, Ontario.Dossier 919-DYV Bulletin 3-15-68 Maurice Canada, Louvicourt, Abitibi, P.Q.Dossier #127-DYL Bulletin 3-17-45 Centre de Location Pyramide Inc., 79, boul.St-Jean Baptiste, Châteauguay, Cté Châteauguay, P.Q.Dossier #934-DYV Bulletin 3-19-69 Location Chouinard Inc., 6605, rue Magloire, Montréal #458, P.Q.Dossier #927-DYV Bulletin 3-19-70 Rouyn Drive Yourself Ltd., 388, rue Larivière, Rouyn, P.Q.Dossier #163-DY & #153-DYV Bulletin 3-19-57 Compact Rent a Car Ltd.a/s Budget Rent a Car de Montreal, 1460, rue Guy, Montréal #107, P.Q.Dossier #748-DY Bulletin 3-19-63 Rôle Mtl.3882 La requérante a demandé à la Régie l'autorisation de louer des véhicules de commerce ou de livraison (remorques seulement) à long terme (une année ou plus) pour usage dans la province de Québec, de la firme ayant son siège social à P.O.Box 84, Don Mills, Ontario.Rôle Mtl.3989 Le requérant demande à la Régie l'autorisation d'effectuer la location de véhicules de commerce (remorques-citernes) à Senncterre Transport Inc., 360 -4e Rue Ouest, Senncterre et ce, suivant les termes du contrat déposé à la Régie en date du 21 juin 1972.Rôle Mtl.4008 La requérante demande l'autorisation de donner les services suivants: Service No 1 : Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) à long terme (un an et plus).Service No 2: Location à court terme de véhicule de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la Route à 79 boul.St-Jean Baptiste.Rôle Mtl.4011 La requérante demande l'autorisation d'effectuer la location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) à long terme, un an et plus.Rôle Mtl.4014 La requérante qui détient de la Régie des permis pour les services suivants: Service No 1 : Location dé véhicules de promenade, à court terme, à 388, rue Larivière, Rouyn 1086-3e Avenue, Val d'Or Aéroport de Val d'Or Rue Principale Sud, Amos Aéroport Rouyn Noranda.Service No 2 : Location à court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la Route à: 388, rue Larivière, Rouyn, Aéroport de Val d'Or.Demande l'autorisation d'ouvrir les succursales suivantes: Rue Principale, Matagami Aéroport de Matagami.Rôle Mtl.4016 La requérante qui détient de la Régie un permis pour le service suivant: Location de véhicules de promenade (automobiles & station-wagons) à court terme à: 904 Belmont (Central Station) 1460, rue Guy, Montréal 107 Aéroport international de Montréal à: Dorval (Terminus Aéroport.) Une succursale dans la section internationale.Une succursale dans la section locale.Succursales auxiliaires dans la zone du service à: 1625, rue Cardinal, Dorval, 1-118, rue Cardinal, Dorval, Airport Hilton Hotel, Dorval, 4411, Boul.de la Concorde, Laval, Coin du Séminaire et du Boulevard Gouin, à St-Jean, Montreal Aero Centre, 9785, Ave.Ryan, Dorval, 131, 5c Avenue, Chibougamau (Abitibi-Est).Demande l'autorisation d'ouvrir une succursale à l'Aéroport de Chibougamau. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1978, 105' année, n° Il 2073 RENTAL Train Trailer Rentals Ltd., c/o Me Adrien R.Paquette, 200 St.James West, Suite 900, Montreal 126, P.Q.Head Office: P.O.Box 84, Don Mills, Ontario.File 1919-DYV Bulletin 3-15-68 Maurice Canada, Louvicourt, Abitibi, P.Q.File #127-DYL Bulletin 3-17-45 Centre de Location Pyramide Inc., 79 St.Jean Baptiste Boulevard, Châteauguay, County of Châteauguay, P.Q.File #934-DYV Bulletin 3-19-69 Location Chouinard Inc., 6605 Magloire Street, Montreal 458, P.Q.File jf927-DYV Bulletin 3-19-70 Rouyn Drive Yourself Ltd.388 Larivière Street, Rouyn, P.Q.File #163-DY & #153-DYV Bulletin 3-19-57 Compact Rent a Car Ltd., c/o Budget Rent a Car of Montreal, 1460 Guy Street, Montreal 107, P.Q.File #748-DY Bulletin 3-19-63 Roll Mtl 3882 The applicant applied to the Board for authorization to lease commercial and delivery vehicles (trailers only) on a long term basis (one year or over) to be used in the province of Québec at P.Q., at P.O.Box 84, Don Mills.Ontario.Roll Mtl 3989 The applicant requests the Board's permission to rent commercial vehicles (trailer-type tank truck) to Senncterre Transport Inc., 360 \u2014 4lh Street West, Senneterre, under the terms of the contract deposited with the Board on June 21, 1972.Roll Mtl 4008 The applicant wishes the permission to provide the following services: Service No.1: Long-term rental of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) (one year and more).Service No.2: Short-term rental of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) according to the Highway Code at 79 St.Jean Baptiste Boulevard.Roll Mtl 4011 The applicant requests permission for long-term rental of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers), for a duration of one year and more.Roll Mtl 4014 The applicant who holds permits from the Board for the following services: Service No.1 : Short-term rental of family cars, at 388 Larivière Street, Rotiyn, 1086-3rd Avenue, Val d'Or, Val d'Or Airport, Principale Street South, Amos, Rouyn-Noranda Airport.Service No.2: Short-term rental of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) according to the Highway Code at 388 Larivière Street, Rouyn, Val d'Or Airport.Requests permission to open the following branches: Principale Street, Matagami, Matagami Airport.Roll Mtl 4016 The applicant which holds a permit from the Board for the following service: Short-term of family cars (automobiles and station-wagons): at 904 Belmont (Central Station); 1460 Guy Street, Montreal 107; Montreal International Airport at: Dorval (Airport Terminal); One counter on the International side; One counter on the Domestic side; Auxiliary Counters, in the service area at: 1625 Cardinal Street, Dorval; 1-118 Cardinal St., Dorval; Airport Hilton Hotel, Dorval; 4411 de la Concorde Boulevard, Laval; Corner of Séminaire and Gouin Boulevard, in St.Jean; Montreal Aero Centre, 9785 Ryan Avenue, Dorval; 131 - 5th Avenue, Chibougamau (Abitibi-East); Requests permission to open a branch at the Chibougamau Airport. 2074 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.11 U-Haul Co.(Canada) Ltd., 4137 North Service Road, Queen Elizabeth Highway, Burlington, Ontario et a/s M.Armand Hutton 7190, rue St-Jacques ouest Montréal, P.Q.Dossier #136-DYV Bulletin 3-22-58 Martin & Stewart Ltd., R.R.#4, Howick, Comté de Châteauguay, P.Q.Les Entreprises Désourdy Inc., Montée Si-Luc, Comté St-Jean, P.Q.Dossier #115-DYL Bulletin 3-19-64 CAMIONNAGE Transol Inc., 124, rue St-Pierre, Québec 2, P.Q.Dossier #18627-V Bulletin 3-18-3 Bergeron, J.André, CP.278, Matagami, Cté Abitibi est, P.Q.Dossier #22478-V Bulletin 3-20-29 Monsieur Jean-Guy Rochon, 115, boul.Saint-Canut, Saint-Canut, P.Q.Dossier #22063-V Bulletin 3-19-23 Rôle Mtl.4073 La requérante qui détient les permis suivants de la Régie: Service No 1 : Location de véhicules de commerce (remorques qui s'attachent aux véhicules de promenade \u2014 (automobiles et station-wagons) et ayant des carrosseries à ridelles de dimensions 4' x 8' et de 5' x 10', à court terme, de succursales dans la province de Québec.Service No 2: Location à court terme de véhicules de commerce (camions) pour usage dans une seule direction, par l'entremise des représentants autorisés dont la liste est déposée à la Régie et sous réserve de modification.Restriction: 1.Location strictement réservée aux particuliers \u2014 pour le transport d'effets personnels, en provenance de localités situées à l'extérieur de la province de Québec, à destination de localités situées à l'intérieur de ladite province, et de points dans la province de Québec vers l'extérieur.Elle a demandé à la Régie la modification du Service No 2, qui se lira à l'avenir comme suit: Service No 2 : Location à court terme de véhicules de commerce (camions) pour usage dans les deux directions, par l'entremise des représentants autorisés dont la liste est déposée à la Régie et sous réserve de modification.Service No 3 : Location à court terme de véhicules de commerce (camions) pour usage à un ou deux sens, chez des représentants autorisés dans la province de Québec pour service partout au Canada.Rôle Mtl.3998 La requérante demande à la Régie l'autorisation d'effectuer la location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs et remorques) à long terme, (un an et plus).Rôle Mtl.4013 La requérante qui détient de la Régie un permis l'autorisant à louer des véhicules de commerce (remorques) à Gilles Hébert Transport; Demande une modification de son permis pour ajouter M.Germain Lécuyer No 17723-V du 3730, Grande Ligne, Chambly, suivant les termes du contrat déposé à la Régie, en date du 5 octobre 1972.Rôle Mtl.2269 La requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint \u2014 longue distance \u2014 route restreinte \u2014 contrat \u2014 citerne.De Berthier à Montréal, pour le transport d'alcool, par camion citerne, pour le compte de La Société des Alcools du Québec.Rôle Mtl.4006 Le requérant désire ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint \u2014 longue distance \u2014 route restreinte.De Matagami à tous les endroits situés dans le territoire de la Baie James, pour le transport d'explosifs, agents d'explosifs et de substances servant au dynamitage (blasting agents), et retour avec marchandises refusées ou avariées.Rôle Mtl 4020 Le requérant désire ajouter à son permis, le service suivant: Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat -De Montréal à Lavaltrie, Saint-Canut et Saint-Joseph du Lac, pour le transport d'huile légère distillée, par camion-citerne de 7,000 gallons, pour le compte de Pétroles Hochelaga Inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 106' année, n° Il 2075 U-Haul Co.(Canada) Ltd., 4137 North Service Road, Queen Elizabeth Highway, Burlington, Ontario.and c/o Mr.Armand Hutton, 7190 St.James Street West, Montreal, P.Q.File #136-DYV Bulletin 3-22-58 Martin & Stewart Ltd., R.R.4, Howick, County of Châteauguay, P.Q.File #931-DYV Bulletin 3-19-71 Les Entreprises Désourdy Inc., Montée St.Luc, County of St.Jean, P.Q.File 115-DYL Bulletin 3-19-64 TRUCKING Transol Inc., 124 St.Pierre Street, Québec 2, P.Q.File #18627-V Bulletin 3-18-3 Bergeron, J.André, P.O.Box 278, Matagami, County of Abitibi-East, P.Q.File #22478-V Bulletin 3-20-29 Mr.Jean-Guy Rochon, 115 St.Canut Boulevard, St.Canut, P.Q.File #22063-V Bulletin 3-19-23 Roll Mtl 4073 The applicant who holds from the Board the following permits: Service No.1 : Leasing of commercial vehicles (trailers to be attached to pleasure motor vehicles-automobiles and station-wagons) and having dimensions of 4' x 8' stake body and 5' x 10' stake body on a short term basis at agencies in the Province of Québec.Service No.2: Leasing of commercial vehicles (trucks) on a short-term basis for use one way through authorized dealers of which the list is supplied to the Board and subject to modification.Restriction No.1 : Leasing strictly limited to individuals-for moving of personal belongings, from places outside to places inside the Province of Québec and, from places inside to places outside the Province of Québec.Applied to the Board for modification of Service 2, to read in future as follows: Service No.2: Leasing of commercial vehicles (trucks) on a short-term basis for use two ways through authorized dealers of which the list is supplied to the Board and subject to modification.Service No.3: Leasing of commercial vehicles (trucks) on a short-term basis for use one or two ways from authorized dealers in the Province of Québec to any place in Canada.Roll Mtl 3998 The applicant applied to the Board for authorization to lease commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) on a long basis (one year or over).Roll Mtl 4013 The applicant holds a permit from the Board authorizing it to rent commercial vehicles (trailers) to Gilles Hébert Transport; Requests a modification to his permit by adding Mr.Germain Lécuyer 17724-V of 3730 Grande Ligne, Chambly, according to the terms of a contract deposited with the Board, on October 5, 1972.Roll Mtl 2269 The applicant wishes to add the following service to his permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - tanker -From Berthier to Montreal, for the transportation of alcohol, by container road carrier, for the account of the Québec Liquor Corporation.Roll Mtl 4006 The applicant wishes to add the following service to his permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - From Matagami to any locality situated in the James Bay territory, for the transportation of explosives, blasting equipment and substances used for dynamiting, and return with refused or damaged merchandise.Roll Mtl 4020 The applicant wishes to add the following service to his permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract -From Montreal to Lavaltrie, St.Canut and St.Joseph du Lac, for the transportation of lightly distilled oil, by road tanker of a capacity of 7,000 gallons, for the account of Pétroles Hochelaga Inc. 2076 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.U Biais & Langlois Inc., CP.188, Matagami, Comté Abitibi, P.Q.Dossier #22317-V Bulletin 3-20-41 Biais & Langlois Inc., Matagami, Comté Abitibi, P.Q.Dossier #22317-V Bulletin 3-20-2 Clébert Beaudin, St-Chrysostôme, Comté Châteauguay, P.Q.Dossier #22372-V Bulletin 3-20-6 Vachon Transport Inc., 10,874, Saint-Vital, Montréal-Nord 459, Que.Dossier #2958-V Bulletin 3-20-39 Murphy Cartage Inc., 8295, rue Pascal-Gagnon, Saint-Léonard, Montréal 458.Dossier #17002-V Bulletin 3-20-43 Rôle Mtl 4021 La requérante désire ajouter le service suivant à son permis: Trai^sport général - longue distance - route restreinte - De Matagami aux sites des travaux d'aménagements hydro-électriques, miniers, industriels, forestiers et touristiques de la Baie James et retour.Rôle Mtl 4022 Transport général - service local - Matagami et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit.Le requérant désire ajouter à son permis, le service suivant: Transport général - longue distance - territoire - De Matagami à tous les endroits situés dans le territoire de la Baie James, pour le transport de marchandises générales.Rôle Mtl 4023 Le requérant désire ajouter le service suivant: Transport restreint - longue distance - rayon - contrat - De Hemmingford à tous les points situés dans un rayon de 100 milles des limites de ladite municipalité, pour le transport de jus de pomme, par camion-citerne, pour le compte de Beattie & Son Inc., Hemmingford.Rôle Mtl 4030 La requérante désire ajouter à son permis, les services suivants: 1.Transport restreint - longue distance - rayon - contrat - 1.De Montréal à ailleurs dans un rayon de 200 milles, et retour, pour le transport de meubles neufs et usagés non emballés, par camions spécialement agencés, pour le transport de meubles, pour le compte de N.G.Valiquette Ltée, Langelier Valiquette Ltée, et Distributeurs Valiquette Ltée.2.Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - 2.De Montréal à la frontière Québec-Ontario (Ports d'entrée: Hull, Grenvillc et Pointe Fortune), destination et origine: Ottawa, et retour, pour le transport de meubles neufs et usagés non emballés, par camions spécialement agencés, pour le transport de meubles pour le compte de N.G.Valiquette Ltée, Langelier Valiquette Ltée, Distributeurs Valiquette Ltée.Droit additionnel: Le détenteur aura le droit de consolider la marchandise des (3) expéditrices nommées ci-haut, nonobstant les articles 41, 44, paragraphe 13, de l'Ordonnance Générale sur le Camionnage.Condition: Si le permis est accordé, la requérante devra produire à la Régie un permis connexe émis par l'Ontario Highway Transport Board.Rôle Mtl 4033 Clause concernée: d) Transport restreint - longue distance - rayon - contrat - d) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 200 milles de ladite ville, pour le transport de produits alimentaires, pour le compte de The H.J.Heinz Co.of Canada Limited.Restriction: En donnant le service autorisé par la clause d ci-dessus Murphy Carnage Inc., n'aura pas le droit de desservir La Tuque. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 106' année, n° IL 2077 Biais & Langlois Inc., P.O.Box 188, Matagami, County of Abitibi, P.Q.File #22317-V Bulletin 3-20-41 Biais & Langlois Inc., Matagami, County of Abitibi, P.Q.File #22317-V Bulletin 3-20-2 Clébert Beaudin, St.Chrysostome, County of Châteauguay, P.Q.File #22373-V Bulletin 3-20-6 Vachon Transport Inc., 10,874 St.Vital, Montreal-North 459, Québec.File #2958-V Bulletin 3-20-39 Murphy Cartage Inc., 8295 Pascal-Gagnon Street, St.Léonard, Montreal 458 File 117002-V Bulletin 3-20-43 Roll Mtl 4021 The applicant wishes to add Ihe following service to its permit: General trucking - long distance - restricted route - From Matagami to the sites of the hydro-electric, mining, industrial, forestry and touristic developments of James Bay and return.Roll Mtl 4022 General trucking - local service - Matagami and any locality situated over an area of no more than 5 miles from the limits of the said locality.The applicant wishes to add the following service to its permit: General trucking - long distance - territory - From Matagami to any locality situated in the James Bay territory, for the transportation of general merchandise.Roll Mtl 4023 The applicant wishes to add the following service : Restricted trucking - long distance - radius - contract - From Hemmingford to any point located within a radius of 100 miles from the limits of the said Municipality, for the transportation of apple juice, by road tanker, for the account of Beattie & Son Inc., Hemmingford.Roll Mtl 4030 The applicant wishes to add the following services to its permit: 1.Restricted trucking - long distance - radius - contract 1.From Montreal to elsewhere within a radius, of 200 mile and return, for the transportation of non-wrapped new and old furniture, by trucks particularly equipped for the transportation of furniture, for the account of N.G.Valiquette Ltée, Langelier Valiquette Ltée, and Distributeurs Valiquette Ltée.2.Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - 2.From Montreal to the Québec-Ontario border (Ports of entry: Hull, Grenville and Pointe Fortune), destination and origin: Ottawa and return, for the transportation of non-wrapped new and old furniture, by trucks particularly equipped for the transportation of furniture, for the account of N.G.Valiquette Ltée, Langelier Valiquette Ltée, Distributeurs Valiquette Ltée.Additional right: The holder will have the right to consolidate the merchandise of the (3) shippers hereinabove named, notwithstanding articles 41, 44, paragraph 13, of the General Ordinance on Trucking.Condition: If the permit is granted, the applicant must produce to the Board a related l>ermit issued by the Ontario Highway Transport Board.Roll Mtl 4033 Clause concerned: (d) Restricted trucking - long distance radius - contract - (er, CM.:.2424.Boisvcrt, André.2428A.P-3.4.5.7 et / and 8.112.81.104-2 et /and 105.Les Placements Céma Inc.2428B.166.Roux, Armand.2431.310.Duma-, Marcel.2431.451.Trudcl, Claude.2431.768 et / and P769.Penaud, Sylva.2431.774.Bisson, Louis-Philippe.2434.30.Parent, Ghislain & at.2434 .32.Marquis, André B.2434 .37.Brochu, Mile / Miss M.-Marthe.2434 .51.Gagné, Roger.2436-2439.46-65.Les immeubles ci-dessus décrits sont tous du cadastre officiel de la paroisse St-Sauveur, division d'enregistrement de Québec, et sont situés en la ville de Vanier.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.La vente sera en outre sujette au droit de retrait et aux autres dispositions de la Loi de la Commission municipale du Québec.L'énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles a été autorisée par la Commission municipale du Québec par ledit arrêté, conformément aux dispositions de l'article 550 de la Loi des cités et villes.Donné à Vanier, ce 28e jour de mars 1973.Le greffier, 51301-14-2-o Roger Gauvin, o.m.a.The immoveables hereinabove described are all of the official cadastre for the Parish of St.Sauveur, Québec Registration Division, and are located in the Town of Vanier.The adjudication price of each of these immoveables will be payable immediately.The sale will, moreover, be subject to the right of repurchase and to the other provisions of the Québec Municipal Commission Act.The abridged list of the cadastral numbers of the immoveables was authorized by the Québec Municipal Commission by said Order, in conformity with the provisions of section 550 of the Cities and Towns Act.Given in Vanier, this 28th day of March, 1973.Roger Gauvin, cm.o., 51301-14-2 City Clerk. 2116 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 197S, Vol.105, No.11 Régie des Marches Agricoles du Quebec Quebec Agricultural Marketing Board Plan Conjoint des Producteurs de Lait Nature du Comté de Portneuf Vu la décision rendue par la Régie mettant fin au Plan Conjoint des Producteurs de Lait Nature du Comté de Portneuf, prenez avis que les producteurs intéressés réunis en assemblée générale le 28 mars 1973 ont désigné la personne suivante comme liquidateur, tel qu'il est stipulé à la section VI-A de la Loi des Marchés Agricoles: M.Armand Brassard, 1787 Boul.Hamel, Québec 8, P.Q.51278-0 Armand Brassard.The Portneuf County Whole Milk Producers' Joint Plan Whereas the Board has made a ruling terminating the Portneuf County Whole Milk Producers' Joint Plan, take notice that the interested producers at their general meeting of March 28, 1973 appointed the following person liquidator, in conformity with Division VI-A of the Agricultural Marketing Act: Mr.Armand Brassard, 1787 Hamel Blvd., Québec 8, P.Q.51278-0 Armand Brassard.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licensed Inteuropa Anslalt fiir Handel und Industrie Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Inteuropa Anstalt lUr Handel und Industrie » a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Amédéo Gatti, industriel, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au numéro 1010, Côte du Beaver Hall, suite 804, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.51176-o PA: 12-73 IU International Corporation Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « IU International Corporation » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est la compagnie « C.T.Corporation System (Canada) Ltd.», 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.51176 PA: 4-73 Inteuropa Anstalt fiir Handel und Industrie Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Inteuropa Anstalt fllr Handel und Industrie\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the Company is Mr.Amédéo Gatti, industrialist, of Montreal.The principal office of the Company in the Province is at 1010 Beaver Hall Hill, Suite 804, Montreal, Judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.51176 PA: 12-73 IU International Corporation Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"IU International Corporation\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is \"C.T.Corporation System (Canada), Ltd.\", 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, Judicial District of Québec.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.51176-0 PA: 4-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, «° H 2117 Hometown Stores Limited Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « Hometown Stores Limited » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur John G.Kirkpatrick, cr., de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 1, place Ville Marie, suite 7Ô0, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Fernand Lalonde.51176 PA: 19-73 Ventes par licitation Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal / TJEDERAL CONSTRUCTION LIM-No 770 795.S ITED, corps politique et incorporé, ^ dûment constitué comme tel, ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, demanderesse, va LA SUCCESSION DE CHAIM (alias Jaime, alias Haim, alias Hakim) RABICEW, comprenant les personnes suivantes: dame Bertha Bernadskaia ou Bernadska, épouse dudit Jaime Rabicew; Waldamar Rabicew, son fils, et sa fille, dame Elizabeth Rabicew, épouse de Ludovik Solar Hartmann, tous de la ville de Caracas, république de Venezuela, et Valentin Majdaniw, des ville et district de Montréal, en sa qualité de curateur (ou de tuteur particulier) (les deux enfants mineurs, Lilian Solar Hartmann et Eduardo Solar Hartmann, de nationalité vénézuélienne, issus du marriage de dame Elizabeth Rabicew à Ludovik Solar Hartmann, défendeurs.Un lot de terre situé en la paroisse de St-Antoine de Longueuil, mesurant vingt-quatre arpents (24) de superficie, faisant partie du lot numéro cinquante-quatre (54) des plan et livre de renvoi officiels de ladite paroisse, étant la juste moitié de toute la partie du lot 54, partie située au sud-est du chemin ci-après mentionné, cette juste moitié étant située et bornée comme suit savoir: en front par le chemin Neuf ou chemin du Tremblay, en arrière par la terre numéro neuf de la paroisse St-Hubert, d'un côté par le lot numéro cinquante-cinq des mêmes plan et livre de renvoi officiels et aussi par une partie de la terre numéro 10 de ladite Paroisse St-Hubert, et de l'autre côté par le résidu de cette partie du lot 54, située du côté sud-est dudit chemin.À distraire toutefois dudit lot, une parcelle de terrain réservée par Louis Joncas, pour lui-même, ses héritiers ou représentants légaux, aux termes de l'acte d'acquisition du vendeur, ci-après décrit, ladite par- Hometown Stores Limited Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"Hometown Stores Limited\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.John G.Kirkpatrick, q.c, of Montreal.The principal office of the company in the Province is at Suite 750, 1 Place Ville Marie, Montreal, judicial District of Montreal.Fernand Lalonde, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.51176-0 PA: 19-73 Sales by Licitation Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( \"REDERAL CONSTRUCTION LIM-No.770 795.\\ *\u2022 ITED, a body politic and corpor- ' ate, duly incorporated as such, having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, plaintiff, vs THE ESTATE OF THE LATE CHAIM (alias Jaime, alias Haim, alias Hakim) RABICEW, comprising the following persons, namely: Dame Bertha Bernadskaia or Bernadska.wife of the said Jaime Rabicew; Waldamar Rabicew, his son, and his daughter Dame Elizabeth Rabicew married to Ludovik Solar Hartmann, all of the City of Caracas, Republic of Venezuela, and Valentin Majdaniw, of the City and District of Montreal, in his quality of curator (or special guardian) to the two minor children Lilian Solar Hartmann and Eduardo Solar Hartmann, of Venezuelan nationality, issue of the marriage of Dame Elizabeth Rabicew to Ludovik Solar Hartmann, Defendants.A lot of land located in the Parish of St.Antoine-de-Longueuil, having a surface area of twenty-four arpents (24), forming part of lot number fifty-four (54) on the official plan and in the book of reference for said Parish, being the exact half of all of that part of lot 54 located to the southeast of the road hereinafter mentioned, this exact half being located and bounded as follows, to wit: in front by \"Chemin Neuf\" of \"Chemin du Tremblay\", in the rear by tract of land number nine in the Parish of St.Hubert, on one side by lot number fifty-five on said official plan and book of reference, and also by a part of tract of land number 10 in said Parish of St.Hubert, and on the other side by the remainder of that part of lot 54 located on the southeast side of said Road.To be deducted however from the said lot and which was reserved by Louis Joncas for himself, his heirs and legal representatives, under the terms of the Vendor's Deed of Acquisition hereinafter described. 2118 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.11 celle de terrain mesurant un arpent de largeur en front et à l'arrière sur une profondeur de cinq cent soixante seize pieds (576').déduite du coin nord-ouest du terrain présentement vendu et bornée comme suit: en front par le chemin du Tremblay, à l'arrière et d'un côté vers l'est par le terrain présentement vendu et de l'autre côté par une partie du lot numéro cinquante-cinq (55) auxdits plan et livre de renvoi officiels, avec la maison dessus construite portant le numéro civique 2230, chemin du Tremblay.Dans l'état où ladite propriété se trouve présentement, avec tous ses droits, membres et circonstances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, 201, place Charles Lemoyne, édifice Montval, Longueuil.(Québec), le HUITIÈME jour de MAI 1973, à OXZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 29 mars 1973.51291 a piece of land, measuring one arpent in width in front and in rear by a depth of five hundred and seventy-six feet (576') and taken from the extreme north westerly corner of the land herein sold and being bounded as follows: in front by Chemin du Tremblay, in rear and on one side towards the East by the land herein sold and on the other side by a part of lot number fifty-five (55) of the said Official Plan and Book of Reference, with the house thereon bearing civic number 2230 Chemin du Tremblay.As the said property now subsists, with all its rights, members and appurtenances; To be sold at the Registry Office of Chambly County, 201 Charles Lemoyne Place, Montval Building, Longueuil, P.Q., on the EIGHTH day of MAY 1973, at ELEVEN\" o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant-Sheriff.Montreal, March 29, 1973.51291-0 Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"TVVME MARIA OLESCHUK, No 05-009616-72.< J-/ ménagère, épouse de Chmigil- Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Laval.155 boulevard Je-Me-Souviens, Laval, P.Q., le NEUVIÈME jour de MAI 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Paul St-Martin.Montréal, ce 29 mars 1973.51283-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Quél>ec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.330-940, ( OAISSE POPULAIRE ST-CLAU-18-000291-73A v- gne et de crédit, Ville de Mont-' Joli, district de Rimouski, demanderesse, vs ADRIEN CARON, résidant à Sayabcc, district de Rimouski, défendeur.Le lot 121, village de Ste-Marie de Sayabec, de figure irrégulière, borné au nord-est par le lot 536, C.N.R., au sud-est par le lot 122, au sud-ouest par le lot 721, avenue Rioux, mesurant 93.2 au nord-est 34 pieds au sud-est, 11.6, 53.4 et 38.2 au sud-ouest contenant en superficie deux mille cinq cent trente-six pieds carrés, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement d'Am-qui, Palais de Justice.Ville d'Amqui, le NEUVIÈME jour de MAI 1973, à ONZE heures de l'avant-midi.Le député-shérif.Bureau du Député-Shérif, Jacques Martin.Rimouski, 30 mars 1973.51286-o vision thirty-six-onc (36-1) of original lot number one thousand five hundred sixteen (1516) on the official cadastre for the Parish of Beauport, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, numbered 531-535 Des Mariniers, Beauport, P.Q.\" To be sold in the Québec Registry Office.10 Chauveau Avenue, Québec, on the ELEVENTH day of MAY, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 3, 1973.51288 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( rPHE CITY OF BEAU-Mun.Court of Beauport.) *\u2022 PORT.B eauport.No.C-317 B.) P.Q.versus JEAN-EUDES { BOUDREAU.0985 - 7th Avenue East, Charlesbourg, Québec 7, P.Q.\"Subdivision forty-eight (48) of original lot number five hundred fifty-four (554-48) on the official cadastre for the Parish of Beauport, with buildings erected thereon, appurtenances anil dependencies, numbered 286 Delage Street.Beauport.P.Q.\" To be sold in the Québec Registry Office.10 Chauveau Avenue.Québec, on the ELEVENTH day of MAY, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 3, 1973.51289 RIMOUSKI Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Rimouski l T ES ML TUELLISTES, a savings No.M.J.513A *-* and credit union, in the Town of V Mont-Joli, District of Rimouski, plaintiff, vs ADRIEN CARON, residing in Sayabcc, District of Rimouski, defendant.Lot 121, Village of Ste.Marie-de-Sayabec, of an irregular configuration, bounded on the northeast by lot 536, C.N.R., on the southeast by lot 122, on the southwest by lot 721, Rioux Avenue, measuring 93.2 on the northeast, 34 feet on the southeast, 11.6, 53.4 and 38.2 on the southwest, having a surface area of two thousand five hundred thirty-six square feet, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold in the Amqui Registry Office, at the Court House, in the Town of Amqui, on the NINTH day of MAY, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Jacques Martin, Deputy Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, March 30, 1973.51286 2126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.Ii Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quebec Cour Supérieure \u2014 District de Rimouski ( EQUIPEMENTS ST PAUL LTÉE, No 5508.\\ corps politique et incorporé, léga- ' lement constitué, ayant une place d'affaires dans les cité et district de Québec, demanderesse, vs LÉO LAVOIE, industriel, domicilié et résidant à Lac-au-Saumon, district de Rimouski, défendeur.Un terrain situé au village de Lac-au-Saumon, contenant quarante pieds (40') de front le long de la rue et vingt-cinq (25') pieds de largeur au bout de la profondeur sur cent pieds (100') de profondeur, faisant partie et distrait des lots connus et désignés sous les numéros trente et un et trente-deux (partie de 31 et partie de 32) du cadastre officiel du rang un du canton Humki, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, borné au nord à quinze pieds de la partie sud de la maison de Charles Routhier ou représentant, à l'est au terrain de Françoise Deschênes, à l'ouest à celui de dame Cléophas Cormier, au sud par le chemin.Pour être vendu au bureau d'enregistrement d'Amqui, Palais de Justice, Ville d'Amqui, le NEUVIÈME jour de MAI, 1973, à DEUX heures TRENTE de l'après-midi.Le députi-shérif, Bureau du Député-Shérif, Jacques Martin.Rimouski, 30 mars 1973.51285-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Rimouski Cour Provinciale, ( /CANADIAN INDUSTRIES No 6830.\\ LTD., corps politique et in- ' corporé légalement constitué ayant une place d'affaires à C.P.10 Montréal, dit district, demanderesse, vs FERDINAND GAGNON, domicilié et résidant à Amqui, district de Rimouski, défendeur.Le lot 18-1 St-Benoit J.L.d'Amqui: Borné au sud-ouest par le chemin Matapédia, au nord-ouest par le lot No 18-2, au nord-est et au sud-est par le lot No 17, mesurant quarante-deux pieds (42*) au nord-est, quarante-deux pieds et six dixièmes (42.6') au sud-ouest par trente-cinq pieds de profondeur; contenant en superficie mille quatre cent quatre-vingts pieds carrés.M.À.(1,480') avec circonstances et dependences ci-dessus construites.Le lot 17-2 St-Benoit J.L.d'Amqui: De figure irrégulière, borné au nord-ouest par les lots 18-3, 18-2, au nord-est par les lots 11-12, 16-1-2, au sud-est par les lots 16-1-2, 17-1-1, au sud-ouest par le lot 18-1 ; mesurant quarante-neuf pieds et quatre dixièmes puis cent vingt-trois pieds au nord-ouest, trente-quatre pieds au nord-est, cent vingt-sept pieds au sud-est, vingt-trois pieds et quatre dixièmes au nord-est, seize pieds puis seize pieds et sept dixièmes au sud-est quarante-deux pieds au sud-ouest; contenant en superficie Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Rimouski /EQUIPEMENTS ST PAUL LTÉE, No.5508.^ body politic and corporate, having ' a place of business in the City and District of Quebec, plaintiff, vs LÉO LAVOIE, industrialist, domiciled and residing at Lac-au-Saumon, District of Rimouski, defendant.A piece of land located in the Village of Lac-au-Saumon, measuring forty feet (40') across in front along the street and twenty-five (25') feet in breadth at the rear, by one hundred feet (100') in depth, forming part of and withdrawn from the lots known and described as numbers thirty-one and thirty-two (Pts.31 and 32) on the official cadastre for Range one in the Township of Humki, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, bounded on the north fifteen feet from the south part of the house belonging to Charles Routhier or representative, on the east by the land belonging to Françoise Deschênes, on the west by the land belonging to Mrs.Cléophas Cormier, on the south by the road.To be sold in the Amqui Registry Office, at the Court House, in the Town of Amqui, on the NINTH day of MAY, 1973, at TWO-THIRTY in the afternoon.Jacques Martin, Deputy Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, March 30, 1973.51285 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Rimouski Provincial Court, ( pANADIAN INDUSTRIES No.6830.< LTD., body politic and cor- >¦ porate legally incorporated having a place of business at P.O.Box 10, Montreal, said District, plaintiff, vs FERDINAND GAGNON, domiciled and residing in Amqui, District of Rimouski, defendant.Lot 18-1 St.Benoit J.L.of Amqui: Bounded on the southwest by the Matapédia Road, on the northwest by lot No.18-2, on the northeast and southeast by lot No.17, measuring forty-two feet (42') on the northeast, forty-two and six-tenths feet (42.6') on the southwest by thirty-five feet in depth; containing a surface area of one thousand four hundred and eighty square feet.E.M.(1,480') with appurtenances and dependencies erected thereon.Lot 17-2 St.Benoit J.L.of Amqui: Of an irregular configuration, bounded on the northwest by lots 18-3, 18-2, on the northeast by lots 11-12, 16-1-2, on the southeast by lots 16-1-2, 17-1-1, on the southwest by lot 18-1; measuring forty-nine and four-tenths feet then one hundred and twenty-three feet on the northwest, thirty-four feet on the northeast, one hundred and twenty-seven feet on the southeast, twenty-three and four-tenths feet on the northeast, sixteen feet then sixteen and seven-tenths feet on the GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2127 cinq mille cent vingt pieds carrés (m.a.) avec circonstances et dependences ci-dessus construites (5,120 p.c.) Le lot 16-1-2 St-Benoit J.L.d'Amqui: De figure irrégulière, borné au nord-ouest et au sud-ouest par le lot 17-2, au nord-est par le lot 11-12, au sud-est par les lots 16-6, 16-5, 16-1-1; mesurant cent vingt-sept pieds au nord-ouest, quarante-cinq pieds au nord-est, soixante-trois pieds puis trente-deux pieds puis vingt-deux pieds et cinq dixièmes au sud-est, vingt-trois pieds et quatre dixièmes au sud-ouest; contenant en superficie quatre mille trois cent trente pieds carrés (m.a.) (4,330 p.c.) avec circonstances et dependences ci-dessus construites.Pour être vendus au bureau d'enregistrement d'Amqui, Palais de justice.Ville d'Amqui, le NEUVIÈME jour de MAI, 1973, à DEUX heures de l'après-midi.Le député-shérif, Bureau du Député-Shérif, Jacques Martin.Rimouski, 30 mars 1973.51284-0 SAGUENAY Canada \u2014 Province de Québec District de Saguenay j CERVICE DE PNEUS INC., C.P.Q.No 78-098.S ^ corps politique et incorporé ' légalement constitué, ayant une place d'affaires dans les cité et district de Québec, vs GHISLAIN DUFOUR, domicilié et résidant à rang St-Charles, La Malbaie, comté de Charlevoix, district de Saguenay.Un lopin de terre sis en ville de la Malbaie, rang St-Charles, étant et composant partie du lot six cent soixante-huit (P.668) au cadastre officiel pour la paroisse St-Étienne de la Malbaie, de grandeur indéterminée mais compris et délimité par les bornes suivantes, savoir: au nord-est, au trait carré du rang St-Charles (François Tremblay) : au nord-ouest, au lot 667 et 669 (Maurice Couturier); au sud-ouest au chemin public; au sud-est, au lot 670 (Adélard Boily); ensemble avec bâtisses dessus construites circonstances et dépendances.Une terre sise en la ville de la Malbaie, rang St-Charlcs, étant et composant partie du lot six cent soixante-dix (P.670) au cadastre officiel pour la paroisse St-Étienne de la Malbaie, mesurant un arpent et quart de largeur sur toute la profondeur du lot et bornée comme suit: au nord-est, au trait carré du Rang St-Charles (François Tremblay) ; au nord-ouest, à partie du lot 670 (Adélard Boily); au sud-ouest à la paroisse de Ste-Agnès; au sud-est, au lot 671 (Ferdinand Lavoie), avec circonstances et dépendances ci-dessus construites.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la Malbaie, district de Saguenay, MERCREDI le NEU- southeast, forty-two feet on the southwest, containing a surface area of five thousand one hundred and twenty square feet (E.M.) with appurtenances and dependencies erected thereon.(5,120 sq.ft.).Lot 16-1-2 St.Benoit J.L.of Amqui: Of an irregular configuration, bounded on the northwest and on the southwest by lot 17-2, on the northeast by lot 11-12, on the southeast by lots 16-6, 16-5, 16-1-1; measuring one hundred and twenty-seven feet on the northwest, forty-five feet on the northeast, sixty-three feet then thirty-two feet then twenty-two and five-tenths feet on the southeast, twenty-three and four-tcnths feet on the southwest; containing a surface area of four thousand three hundred and thirty square feet (E.M.) with appurtenances and dependencies erected thereon.(4,330 sq.ft.) To be sold int he Amqui Registry Office, at the Court House, in the Town of Amqui, on the NINTH day of MAY, 1973, at TWO o'clock in the afternoon.Jacques Martin, Deputy Sheriff's Office, Deputy Sheriff.Rimouski, March 30, 1973.512,84 SAGUENAY Canada \u2014 Province of Québec District of Saguenay , ( OERVTCE DE PNEUS INC., Q.P.C.No 78-098.S « body politic and legally in-' corporated, having a place of business in the City and District of Québec, vs GHISLAIN DUFOUR, domiciled and residing in St.Charles Range, La Malbuic, County of Charlevoix, District of Saguenay.A plot of land located in the Town of La Malbaie, St.Charles Range, consisting of and being part of lot six hundred sixty-eight (Ft.668) on the official cadastre for the Parish of St.Étienne-de-la-Malbaie, of indefinite dimensions but comprised within and delimited by the following boundaries, namely: on the northeast by the boundary line of St.Charles Range (François Tremblay); on the northwest by lot 667 and 669 (Maurice Couturier); on the southwest by the public road; on the southeast by lot 670 (Adélard Boily); together with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.A tract of land located in the Town of La Malbaie, St.Charles Range consisting of and being part of lot six hundred seventy (Pt.670) on the official cadastre for the Parish of St.Étienne-de-la-Malbaie, measuring one and one-fourth arpents in width by the entire depth of the lot and bounded as follows: on the northeast by the boundary line of St.Charles Range (François Tremblay); on the northwest by part of lot 670 (Adélard Boily) ; on the southwest by the Parish of Ste.Agnès; on the southeast by lot 671 (Ferdinand Lavoie), with appurtenances and dependencies erected thereon.To be sold in the registy office in La Malbaie, in the District of Saguenay, on WEDNESDAY, of NINTH 2128 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U VIÈME jour de MAI 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Pierre Gaudreault.La Malbaie, le 29 mars 1973.51273-0 Canada \u2014 Province de Québec-District de Saguenay ( A SSELIN AUTOMOBILE INC., C.P.S.-1666.^ corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaire à La Malbaie, comté de Charlevoix, tu DONAT LA VOIE, domicilié et résidant à St-Siméon, comté de Charlevoix, P.Q.< Un certain terrain situé en le village de St-Siméon dans le rang de Port-au-Persil, à prendre ledit terrain le long de la ligne de division suivant la ligne ou clôture actuelle toute division, mesurant en profondeur tout le terrain qu'il peut y avoir à partir du chemin public à aller à une ligne tirée parallèlement en longeant le solagc extérieur de la nouvelle maison construite sur ledit terrain, par la largeur qu'il peut y avoir à partir de la ligne susdite de division avec le terrain de Antonio Simard courant nord-est jusqu'à une nouvelle rue qui porterait le nom de rue Morin et borné comme suit: En front au sud-est au chemin public; au nord-est, à la rue Morin ; au nord-ouest, à une ligne tirée parallèlement et longeant le solage extérieur de la nouvelle résidence soit au terrain de David Morin; au sud-ouest, à ladite ligne de division avec le terrain de Antonio Simard, ensemble ledit immeuble avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, ledit terrain étant et composant partie du lot 65 (P-65) au cadastre officiel pour paroisse de St-Siméon, dans la Seigneurie Mount-Murray ».Pour être vendu au bureau d'enregistrement de La Malbaie, district de Saguenay, JEUDI, le DIXIÈME jour de MAI 1973 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Pierre Gaudreault.La Malbaie, le 29 mars 1973.51293-0 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris District de St-François Cour Provinciale, ( OHARLAND & LEDUC INC., (Magog), ) ' corporation légalement cons-No M-3922.) tituée ayant une place d'affaires ' en la cité de Magog, district de St-François, demanderesse, vs HENRI LESPINASSE, résidant en la ville de Mont-St-Hilaire, district de St-Hyacinthe, défendeur.« Une ferme dans le canton de Magog, désignée comme étant: day of MAY, 1973, at TEN o'clock in the forenoon Pierre Gaudreault, Sheriff's Office, Sheriff.La Malbaie, March 29, 1973.51273 Canada \u2014 Province of Québec District of Saguenay ( A SSELIN AUTOMOBILE INC., S.P.C.4666.^ a corporation legally incorporated, ' having its principal place of business in La Malbaie, County of Charlevoix, vs DONAT LAV01E, domiciled and residing in St.Simeon, County of Charlevoix, P.Q.\"A certain piece of land located in the Village of St.Simeon, in Port-au-Persil Range, the said land to be taken along the dividing line that lies along the present line or fence, whole division, measuring in depth, all the distance that there may be between the public road and a line drawn parallel to and along the outside of the foundation of the new house built on said land, and in width the distance that there may be between the aforesaid dividing line and the land belonging to Antonio Simard, running northeast to a new street which would be known as Morin Street and bounded as follows: In front on the southeast by the public road; on the northeast by Morin Street; on the northwest by a line drawn parallel to and along the outside of the foundation of the new residence, that is, the land belonging to David Morin; on the southwest by the said dividing line with the land of Antonio Simard, the said immoveable together with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, the said piece of land being and forming part of lot 65 (Pt.65) on the official cadastre for the Parish of St.Simeon, in the Mount Murray Seigniory.To be sold in La Malbaie Registry Office, District of Saguenay, on THURSDAY, the TENTH day of MAY, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Pierre Gaudreault, Sheriff's Office, Sheriff.La Malbaie, March 29, 1973.51293 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris District of St.François Provincial Court, / pHARLAND & LEDUC INC., (Magog), 1 a corporation legally incor- No.M-3922.j porated, having a place of business ' in the City of Magog, District of St.François, plaintifT, vs HENRI LESPINASSE.residing in the Town of Mont St.Hilaire, District of St.Hyacinthe, defendant.\"A farm in the Township of Magog, described as being: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° U 2129 o) Le lot No 1-C dans le 12ième rang du canton de Magog-Hatley, sauf à déduire les 10 acres nord-ouest de «« lot, lequel terrain déduit, à la même largeur du nord au sud que les lots Nos 1-A et 1-H dans ledit 12ième rang par une profondeur de 24 rods de l'est à l'ouest.Ce terrain déduit est borné au nord par partie des lots Nos 2-A et 2-D, XII Rang, vers l'ouest par les lots Nos 1-A et 1-15, XII Rang; vers l'est et le sud par le reste dudit lot No 1-C; b) Toute cette partie du lot No 1-A dans le 13ième rang des lots du canton de Magog située à l'est du chemin public tel qu'existant actuellement après déduction d'un terrain de 150 pieds sur chacune de ses faces borné vers le nord par le lot No 1-B; vers l'ouest par le chemin public; vers l'est et le sud par le reste dudit lot No 1-A.Ce terrain déduit a été vendu à Mlle Ginette Côté le 7 juin 19G3 suivant acte passé devant le notaire soussigné et dont copie fut enregistrée à Stanstead sous No 75051 ; c) Toute cette partie du lot No 1-A dans le 13ième rang du canton de Magog-Hatley, s'étendant entre la ligne de division entre les cantons de Stanstead et de Magog (au sud): la limite ouest de la route nationale telle qu'elle existe actuellement (à l'est); la limite sud du chemin courant à travers ledit lot No 1-A de l'est à l'ouest (au nord) et la limite ouest d'un chemin privé courant du nord au sud à travers ledit lot No 1-A et longeant la limite est de ces parties dudit lot No 1-A vendues à MM.G.Saunderson, Ross Bennett, H.Hudson, E.Longpré, 1'.Longpré, F.Beaulieu, G.La-casse, et C.Demcrs et al., aux termes de ventes enregistrées à Stanstead sous les Nos 80124, 80501, 78483, 79831, 74747, 74922, 74746 et 67216.Avec et y compris cette lisière de terrain de 100 pieds de largeur s'étendant du nord de la ligne de division entre les cantons de Stanstead et de Magog et à l'ouest de la limite ouest du chemin privé susmentionné et ce jusqu'au Lac Crystal.Les 40 pieds ouest de cette partie dudit lot 1-A longeant les propriétés Saunderson et autres susmentionnées ainsi que le terrain de 100 pieds de largeur s'étendant entre le chemin privé et le lac le long de la ligne de division entre les cantons de Magog et de Stanstead sont vacants, doivent le demeurer et servent de passage pour avoir accès au chemin public et au lac pour le bénéfice des propriétaires et occupants du lot No.1-A, 13ième rang, Magog-Hatley.d) Les bâtisses érigées sur lesdits lots et parties de lot, exceptant: a) Des droits de mines et minéraux au profit de British American Land Co., suivant acte enregistré à Stanstead le 18 octobre 1895, B.39, No 2414; /;) Du droit à un réseau électrique, planter des poteaux, droit tie passage au profit de Southern Canada Power Co., suivant acte sous seing privé, 5 mars 1925, enregistré à Stanstead sous le No 25507, B.53; c) Du droit à un réseau électrique, planter des poteaux, droit de passage, etc., au profit de la Coopérative d'Électricité du canton de Magog, suivant acte sous (a) Lot No.1-C in the 12th Range of the Township of Magog-Hatley.less and to withdraw the 10 acres northwest of this lot, which land withdrawn has the same width from north to south as lots Nos.1-A and 1-B in the said 12lh Range by a depth of 24 rods from east to west.This land withdrawn is bounded on the north by part of lots Nos.2-A and 2-D, Range XII, towards the west by lots Nos.1-A and 1-B, Range XIT; towards the east and south by the remainder of said lot No.1-C; (i) All this part of lot No.1-A in the 13th Range of the lots of the Towmship of Magog, located cast of the public road, as it now exists after withdrawal of a piece of land of 150 feel on each of its sides, bounded towards the north by lot No.1-B; towards the west by the public road; towards the east and south by the remainder of said lot No.1-A.This piece of land withdrawn was sold to Miss Ginette Côté, on June 7, 1963 under a deed executed before the undersigned notary, a copy of which was registered in Stanstead under No.75051; (c) All this part of lot No.l-A in the 13th Range of the Township of Magog-Hatley, extending between the division line between the Township of Stanstead and Magog (on the south); the weslern boundary of the national Highway as it now exists (on the east); the southern boundary of the road crossing said lot No.1-A from est to west (on the north) and the western boundary of a private road crossing said lot No.1-A from north to south and along the eastern boundary of these parts of said lot No.1-A sold to Messrs.G.Saunderson, Ross Bennett, H.Hudson, E.Longpré, P.Longpré, F.Beaulieu.G.Laçasse, and C.Demers et al., under the terms of the sales registered in Stanstead under Nos.80124, 80501.78483, 79831, 74747, 74922, 74746 and 67216.Together with and including this strip of land of 100 feet in width extending on the north of the division line between the Townships of Stanstead and Magog and on the west of the western boundary of the above mentioned private road, lo Crystal Lake.The 40 feet west of this part of said lot 1-A along the properties belonging to Saunderson and the others above mentioned, together with the piece of land of 100 fect in width extending between the private road and the lake along the division line between the Townships of Magog and Stanstead, are vacant, must remain so and serve as a passage to reach the public road and the lake for the benefit of the proprietors and occupants of lot No.1-A, 13th Range, Magog-Hatley.(d) The buildings erected on the said lots and parts of lot, excluding: (a) Mining and mineral rights in favor of British American Land Co., under the deed registered in Stanstead on October 18, 1895, B.39, No.2414; (b) A right to an electrical network, setting up posts, a right of way in favor of Southern Canada Power Co., as per a deed under private seal, March 5, 1925, registered in Stanstead under No.25507, B.53; (c) A right to an electrical network, setting up posts, a right of way, etc., in favor of the Coopérative d'Électricité du Canton de Magog, as per a deed under private 2130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U seing privé, 25 mai 1961, enregistré à Stanstead sous le uuméro 70827.» Pour être vendus « en bloc » au bureau d'enregistrement, à Stanstead Plain, MARDI, le HUITIÈME jonr de MAI 1973, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Jean-Guy Bisson.Sherbrooke, le 27 mars 1973.51227-0 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Saint-Hyacinthe i T A CAISSE D'ÉTABLISSEMENT No 20460.\\ DE ST-HYACINTHE, demande- ^ resse, vs LÉO CHAMPIGNY, et YVES BOUFFARD, et MICHEL DAVIGNON, défendeurs, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de la division de Bagot, mis en cause, et LAURENT LANGEVLN, mis en cause.« Une ferme située à St-Dominique, comté de Bagot, connue et désignée comme étant les lots 375 et 376 au cadastre officiel de la paroisse de St-Dominique, de la contenance de 4 arpents de largeur sur 30 arpents de profondeur, plus ou moins, avec tous les bâtiments y érigés, circonstances et dépendances; A distraire cependant les parties suivantes: 1.La partie du lot 376 au cadastre officiel susdit d'une superficie de 164 pieds carrés plus ou moins, vendue au ministère de la voirie par acte devant Me Lucien Lemonde, notaire, le 22 janvier 1969 enregistré à Bagot, sous le numéro 117387; 2.La partie du lot 276 au cadastre officiel susdit réservé par Raoul Dupont aux termes d'un acte de vente par ce dernier au présent emprunteur, ce jour, devant le notaire soussigné (Claude Réal Girard) sous minute 119659, laquelle partie ainsi distraite peut être décrite comme suit: Tenant en front au nord-est au chemin public, d'un côté au nord-ouest et à la profondeur au sud-ouest au résidu dudit lot 376, et d'autre côté au sud-est partie à la partie ci-après décrite et réservée par Raoul Dupont (Ptie 376 et Ptie 375) et partie au résidu dudit lot 376, mesurant 140 pieds de largeur sur une profondeur de 215 pieds, mesures anglaises et précises, la ligne latérale nord-ouest de cette partie distraite étant parallèle mais distante d'environ 120 pieds anglais de la ligne de division des lots 377 et 376 du susdit cadastre, avec tous bâtiments et constructions dessus érigés, réservés en toute propriété par ledit Raoul Dupont; 3.Les parties des lots 375 et 376 au cadastre officiel susdit réservées par Raoul Dupont aux termes d'un acte de vente, par ce dernier au présent emprunteur, ce jour, devant le notaire soussigné (Claude Réal Girard) sous minute 119659, lesquelles parties ainsi seal, May 25, 1961, registered in Stanstead under number 70827.\" To be sold \"en bloc\" at the Registry Office, in Stanstead Plain, on TUESDAY, the EIGHTH day of MAY, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Jean-Guy Bisson, Court House, Assistait! Sheriff.Sherbrooke, March 27, 1973.51227 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Saint-Hyacinthe C T A CAISSE D'ÉTABLISSEMENT No.20460.4 ^ DE ST-HYACINTHE, plaintiff, Ira LÉO CHAMPIGNY, and YVES BOUFFARD, and MICHEL DAVIGNON, defendants, and THE REGISTRAR for the Bagot Registration Division, mis en cause, and LAURENT LANGEVIN, mis en cause.\"A farm located in St.Dominique, County of Bagot, known and described as being lots Nos.375 and 376 on the official cadastre for the Parish of St.Dominique, containing a surface area of four arpents (4) in width by thirty arpents (30) in depth, more or less, with all buildings erected thereon, appurtenances and dependencies; Less and to withdraw however the following parts: 1.Part of lot No.376 on said official cadastre having a surface area of one hundred sixty-four square feet (164') more or less, sold to the Roads Department under a deed executed before Me Lucien Lemonde, notary, on January 22, 1969, registered at Bagot, under number 117,387; 2.Part of lot No.276 on said official cadastre reserved by Raoul Dupont under the terms of a deed of sale by the latter to the present borrower, this day, before the undersigned notary (Claude Réal Girard), under number 119659 of his minutes, the said part thus withdrawn may be described as follows: Bordering in front on the northeast to the public road, on one side, to the northwest and in depth to the southwest to the remainder of said lot No.376, and on the other side on the southeast partly to the part hereinafter described and reserved by Raoul Dupont (Pt.376 and Pt.375) and partly to the remainder of said lot No.376, measuring one hundred forty feet (140') in width by a depth of two hundred fifteen feet (215'), precise English measures, the lateral northwest line of this part withdrawn being parallel but distant by about one hundred and twenty English feet (120') from the division line of lots Nos.377 and 376 of said cadastre, with all the buildings and constructions erected thereon, reserved by said Raoul Dupont as rightful owner.3.Parts of lots Nos 375 and 376 on the said official cadastre, reserved by Raoul Dupont under the terms of a deed of sale, by the latter to the present borrower, this day, before the undersigned notary (Claude Real Girard), under number 119659 of his minutes; said parts GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° IL 2131 distraites peuvent être décrites comme suit: Tenant en froiit au nord-est au chemin public, d'un côté au sud-est à partie dudit lot 375, à la profondeur au sud-ouest à partie desdits lots 375 et 376 et d'autre côté au nord-ouest à la partie ci-haut décrite dudit lot 376 réservée par Raoul Dupont, mesurant 409 pieds de largeur sur 100 pieds de profondeur, mesure anglaise, et précise, la ligne latérale sud-est de cette partie distraite étant parallèle mais distante d'environ 92 pieds anglais de la ligne de division des lots 374 et 375 du susdit cadastre, avec tous bâtiments et constructions dessus érigés réservés en toute propriété par ledit Raoul Dupont; Tel que le tout se trouve actuellement avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes y attachées; » Pour être vendus au bureau d'enregistrement, division de Bagot, à St-Liboire, comté de Bagot, district de Saint-Hyacinthe, MERCREDI, le NEUVIÈME jour de MAI 1973, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Michel Laroche.Saint-Hyacinthe.51226-0 Canada \u2014 Province de Québec District de Saint-Hyacinthe Cour Supérieure, ( T A CAISSE D'ÉTABLISSE-No 20461.< ^ MENT DE ST-HYACIN-' THE, demanderesse, vs LÉO CHAMPIGNY, défendeur et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de la division de Bagot, mis en cause.« 1.Une ferme située en la paroisse de St-Domini-que (9e rang), comté de Bagot, connue et désignée comme étant le lot de terre No 25, au cadastre officiel de la paroisse de St-Dominique, mesurant 3 arpents de front sur 20 arpents 9 perches et 9 pieds de profondeur, et contenant 62 arpents 84 jwrehes et 275 pieds en superficie, plus ou moins; Sujet à une servitude au profit de The Southern Canada Power Co.Ltd., pour ses lignes de transmission électrique suivant acte enregistré à Bagot sous le numéro 73531; 2.Une autre ferme située en la même paroisse, sur le 8e rang, connue et désignée comme étant le lot.de terre No 64 au cadastre officiel de la paroisse de St-Dominique, mesurant 3 arpents de largeur sur 30 arpents de profondeur, et contenant 90 arpents en superficie, plus ou moins; Sujet à une servitude au profit de The Southern Canada Power Co.Ltd., pour ses lignes de transmission électrique, suivant acte enregistré à Bagot sous le numéro 84292, et sujet à une servitude au profit de The Bell Telephone Co., pour la transmission de ses lignes téléphoniques, suivant acte enregistré à Bagot sous le numéro 77790; Avec tous les bâtiments érigés sur les 2 immeubles ci-haut décrits, circonstances et dépendances; » thus withdrawn may be described as follows: bordering in front on the northeast, on the public road, on one side to the southeast on part of said lot No.375, on its depth on the southwest on part of said lots Nos.375 and 376 and on the other side to the northwest on the above described part of said lot No.376 reserved by Raoul Dupont, measuring four hundred rune feet (409') in width by one hundred feet (100') in depth, precise English measure, the southeast lateral line of this withdrawn part being parallel but distant of about ninety-two English feet (92') from the division line of lots Nos.374 and 375 of said cadastre, with all the buildings and constructions erected thereon reserved by said Raoul Dupont as rightful owner.As the whole now subsists with and subject to all active and passive, apparent or unapparent servitudes attached thereto.\" To be sold at Bagot Registration Division Office at St.Liboirc, County of Bagot, District of Saint-Hyacinthe, on WEDNESDAY, the NINTH day of MAY, 1973, at THREE o'clock in the afternoon.Michel Laroche, Sheriff's Office, Sheriff.Saint-Hyacinthe.51226 Canada \u2014 Province of Québec District of St.Hyacinthe Superior Court, f T A CAISSE D'ÉTABLISSE-No.20461.1 ^ MENT DE ST-HYACIN-v THE, plaintiff, vs LÉO CHAMPIGNY, defendant, and THE REGISTRAR for the Bagot registration division office, mis en cause.\"1.A farm located in the Parish of St.Dominique (9th Range), County of Bagot, known and described as being lot of land No.25, on the official cadastre for the Parish of St.Dominique, measuring 3 arpents in front by 20 arpents, 9 perches and 9 feet in depth, and containing a surface area of 62 arpents, 84 perches and 275 feet, more or less; Subject to a servitude in favor of The Southern Canada Power Co.Ltd., for its electrical transmission lines pursuant to a deed registered in Bagot under number 73531 ; 2.Another farm located in the same Parish, in the 8th Range, known and described as being lot of land No.64 of the official cadastre for the Parish of St.Dominique, measuring 3 arpents in width by 30 ai-pcnts in depth, and containing a surface area of 90 arpents more or less; Subject to a servitude in favor of The Southern Canada Power Co.Ltd., for its electrical transmission lines, pursuant to a deed registered in Bagot, under number 84292, and subject to a servitude in favor of The Bell Telephone Co., for the installation of its telephone lines, pursuant to the deed registered in Bagot under number 77790 ; With all buildings erected on the 2 immoveables hereinabove described, appurtenances and dependencies;\" 2132 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol, 105, No.U Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Pour être vendus au bureau d'enregistrement division de Bagpt, à St-Liboire, comté de Bagot, district de Saint-Hyacinthe, MERCREDI le NEUVIÈME jour de MAI 1973, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif, 51225-0 Michel Lahoche.Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014¦ District de Saint-Hyacinthe ( T A CAISSE POPULAIRE DE ST-PIE, No 20454A demanderesse, tu LÉO CHAMPI- ration legally incorporated, having its office and principal place of business at Cap-de-la-Madeleine, District of Three Rivers, defendant, and LES PLACEMENTS D'INTER INC., a corporation legally incorporated, having an office and a place of business in Trois-Rivières, District of Three Rivers, mis en cause, and GENERAL TRUST OF CANADA, a corporation legally incorporated having an office and a place of business at Place Royale in the City of Trois-Rivières, District of Three Rivers, mis en cause, and THE REGISTRAR for the Registration Division of Champlain, having an office in the Municipality of Ste.Geneviève-dc-Batiscan, District of Three Rivers, mis en cause.\"An emplacement located northwest of Fonderie Street, that is, one hundred eight and one-tenth feet (108.1) southwest of Thibeau Street, as now widened, in the City of Cap-de-la-Madelcine, known and described as follows: (a) Part of subdivision lot number one huudred forty-four of original lot four hundred sixteen (416 Pt.144) on the official registration cadastre for the County of Champlain, for the Parish (now City) of Cap-dc-la-Madeleinc ; (b) Subdivision lot number seven hundred sixty-seven of original lot number four hundred sixteen (416-767) of said cadastre; (c) Part of subdivision number seven hundred thirty-seven of original lot number four hundred sixteen (416 Pt.737) of said cadastre; (d) Subdivision lots numbers seven hundred thirty-eight, seven hundred thirty-nine, seven hundred forty, seven hundred forty-one, seven hundred forty-two, seven hundred forty-three, seven hundred forty-four, seven hundred forty-five, seven hundred forty-six and seven hundred forty-seven of original lot number four hundred sixteen (416-738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 and 747) of said cadastre; (e) Subdivision lot number two of lot number seven hundred sixty-five of original lot number four hundred sixteen (416-765-2) of said cadastre, which emplacement is of an irregular configuration and bounded as follows: on the northwest by 487 (C.P.R.), on the northeast by 416-124 (lane), on the southeast by 416 Pt.144 (street), 416 Pt.765 (street), on the southwest by 416-765 (street), 416-76501, 416-74S, on the south by 416-765 (street), and 416-777; measuring 766.0 feet on the northwest, 465.S1 feet on the northeast, 515.40 feet and 79.59 feet on the southeast, 28.3 feet and 166.0 feet on the southwest.69.5 feet anil 242.48 feet on the south, containing a surface area of (296,939 sq.ft.E.M.) two hundred ninety-six thousand nine hundred thirty-nine scpiare feet; with all buildings erected thereon, appurtenances and dependencies; the whole according to the plan drawn by Mr.Roger Gélinas, land-surveyor, and dated September 24, 1963.\" To be sold in the Registry Office, Champlain Registration Division, in the Municipality of Ste.Geneviève-dc-Batiscan, County of Champlain, on YVEDNES- 2138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.106, No.1L MERCREDI, le NEUVIÈME jour du mois de MAI, 1973, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Fernande Turgeon.Trois-Rivières, le 26 mars 1973.51277-o Errata Erratum Proclamation Dans l'avis publié dans l'édition numéro 10 du 10 mars 1973 à la page 1437, au 3ième paragraphe, 3ième ligne, nous aurions dû lire: « numéro 296-73 » au lieu de: « numéro 297-73 ».Erratum District de Richelieu CP.No 405-675 Denis Robillard, Claude Gauthier et al.vs Héritiers Giovani Michelli Dans l'avis publié dans la Gazette officielle du Québec, numéro 12 du 24 mars 1973, à la page 1809, dernier paragraphe, la date de vente aurait dû se lire: « MARDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AVRIL » au lieu de: « MERCREDI, le VINGT-QUATRIÈME jour d'AVRIL ».51177-0 DAY, the NINTH day of MAY, 1973, at THREE o'clock in the afternoon.Fernande Turgeon, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Trois-Rivières, March 26, 1973.51277 Errata Erratum Proclamation In the notice published in issue number 10, dated March 10, 1973, on page 1437 in paragraph 3, line 3, for \"number 297-73\", please read \"296-73\".Erratum District of Richelieu P.C.No.405-675 Denis Robillard, Claude Gauthier et al.vs The Heirs of Giovani Michelli In the notice published number 12 of the Québec Official Gazette dated March, 24, 1973, on page 1809, in the last paragraph, the date of the sale should have read: \"TUESDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL\" instead of: \"WEDNESDAY, the TWENTY-FOURTH day of APRIL\".51177-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 106' année, n° 1 2139 INDEX No 14 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Association coopérative étudiante du campus de St-Félicien {Formation).2057 Coopérative étudiante de l'École secondaire Émile-Nelligan (Formation).2057 Coopérative étudiant du Séminaire Saint-François de Cap-Rouge (Formation).2057 Magasin Co-op de Montmagny (Dissolution).2057 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Club de Matoneige Arvida inc.(L.P.).2018 Estate of Mario Antonio Nicole (Benefit of Inventory).2019 Cowansville, ville-town (Rues et Ruelles-Streets and Lanes).2017 Succession Mario Antonio Nicolo (Bénéfice d'inventaire).2019 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Dubé, Jacqueline Raymond Catherine.2015 Patry, Joseph Gilles.2015 Riopel, Marie Josèphe.2015 Yamine, Paul Boulos Michel.2015 Demandes: ' Applications: Atamanec (Atman), Vladimir.2012 Borowczyk, Henry.2013 Burg, Lawrence Michael.2013 Charbonneau, Joseph Paul Richard.2013 Chauvin, Henrietta Louise.2014 Fishman, Debra Lee.2011 Ghobril, Salim.2013 Grégoire, Sherley.2014 Kleinberger, Kurt I.2013 Kutahialian, Hovanncs Haroutyoun.2012 Lefebvre, Katherine April.2015 Litowitz, Robert.2012 Pichette, Marie Sylvie.2014 Roy, Joseph-Cajetan Marcien.2012 Sadan, Arie.2014 Symonds, Walter Elwood.2014 Topakoglu, Arman.2012 CAISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS ETRANGERES COMPANIES Caisse Populaire Belvédère (Nom-Name ch.).2022 Permis: Licenses: Caisse Populaire Desjardins de Laval des Ra- Hometown Stores Limited.2117 pidcs (La) (M od lerr.).2022 Intcurapa Anstalt fUr Handel und Industrie.2116 Caisse Populaire Duberger (Nom-Name ch.) 2022 Irj international Corporation.2116 COMMISSION COMMISSION COMPAGNIES \u2014 COMPANIES Des Transports du Québec Québec Transport LGI DES ACT Avis spécial concernant les taux et tarifs.2092 Abandon Surrender Décisions.2093 de cha*le °f Charter Requêtes.2058 Allied Shoe Corp.1999 Petitions.2058 Association des Pharmaciens Détaillants de la Special Notice regarding rates and tariffs.2092 Province de Québec inc.1999 2140 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.U Abandon Surrender de charte of Charter (mile) (continued) Harry (îhildrcn's Wear Inc.1999 Berwin InvestmentCorporation.1999 Boulet (J.C.) (1970) limitée.1999 Brand (Bettor) Inc.1999 Brand (Judy) Inc.;.1999 Burnbrooke Holding Corporation.1999 Cartier Automobile inc.1999 Che/.Kraueine limitée.1999 ('ie dc Gestion I'.F.R.inc.(La).1999 Congaean Corporation.1999 Const met ion Jardin inc.1999 Crescent Finance Corporation.1999 Dorion Construction, limitée.1999 fiel .os- Vedettes inc.2000 ficolc de Barbiers Lab rosse ltée.2000 Editions Québec-Montréal inc.2000 Excavations Terrebonne inc.2000 Gainor Investment Corporation.2000 GcmlitoLtd.2000 Glyplnc.2000 Importations Roger Pier ltée.2000 International Dealers & Converters Inc.2000 Kosmos Land Corp.2000 Kres-Kno (Montréal) Ltd.2000 Laboratoires Allemands Réunis Canada inc.2000 Lady's Pride Fashions Inc.2000 Lake Technical Services Ltd.2000 Manoir Charles de Foucault (1900) (Le).2000 Mercure & Frère inc.2000 Mirclis Investments (Québec) Ltd.2000 Morand (René) inc.2000 Wptal Properties Limited.2000 Pier .Roger) Imports Ltd.2000 Placements F.B.L.inc.2000 Placements Roland Halle inc.(\\xs).2000 Plomberie Bernard inc.2000 Westhill ( 'onstruction Ltd.2000 Changement dc nom Change of name Bazar Shopping Center Inc.(Le).199S Celanese Canada Fabrics Limited.1988 Centre Commercial Le Bazar inc.1998 Compagnie de Construction Régionale inc.(La).1999 Construction Northal ltée.1998 Entreprises Lac des Maures inc.1998 Entretien d'Édifice Pinkham & Fils inc.1998 Matério Goulet inc.1998 Northal Construction Ltd.- 1998 Pavillon Mauricien Cap de la Madeleine inc.1998 Pemrep inc.1998 Pinkham & Sons Building Maintenance Inc.1998 Place Kennedy inc.1998 Pouliot, Guérard & Associates Inc.1999 Pouliot, Guérard & Associés inc.1999 Regional Construction Co.Ltd.1999 Ruai Ltd.1999 Société Immobilière du Manoir des Plaines inc.(La).1999 Sybcssinc.1999 Tissus Celanese Canada limitée (Les).1998 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Bresee (Frank) Inc.2001 Confection Christiane Inc.2002 Cyr (Bruno) Compagnie Ltée.2000 Estate Hon.John Hearn Inc.2002 Famous Coffee Shop Inc.2001 Guindon (Charles) inc.2003 Havmor Investments Ltd.2001 Macalton inc.2002 Pétroles de Coaticook Inc.(Les).2001 Rawmatcx Ltd.2001 Reflet dc Bedford Inc.(Le).2002 Restaurant L'Artisan Inc.2002 Sérigraphie Bilodeau limitée.2003 Succession Hon.John Hearn Inc.2002 Three Rivers Chevrolet (1969) Limited.2001 Trois-Rivières Chevrolet (1969) limitée.2001 Divers Miscellaneous Campbell (A.J.) & Company Limited (Dir.) .2003 Canitron Construction Ltd.(Dir.).2003 Cardeau Inc.(Dir.).2004 Centre Communautaire de Pointe-aux-Trembles inc.(Le) (Dir.).2005 Centre de Distributions Soleil (C.D.S.) inc.(Dir.).2005 Centre du Dindon inc.(Le) (Dir.).2005 Chamex, inc.(Dir.).2004 Conseil Régional de Développement de la Région Administrai ivc île Québec 'Dir.) .2003 Constructions Canitron ltée (Les) (Dir.).2003 Den Packaging Corp.(Dir.).2004 Fabraply Inc.(Dir.).2003 Galeries des Iles (Les) (Dir.).2004 Haas & Cavalière inc.(Dir.).2005 Lauzier Electric Inc.(Dir.).2004 Lauzier Électrique inc.(Dir.).2004 Marché de Poissons Portugais ltée (Dir.).2004 Portuguese Fish Market Ltd.(Dir.).2004 Silhouette Health Studio of St.Lambert Ltd.(Dir.).2004 Société d'Emballage Den (Dir.).2004 Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécois limitée (SIMNOQ) (La) (Dir.).2005 Studio de Santé Silhouette de St-Lambert liée (Dir.).2004 Théâtre Marist inc.(Dir.).2005 Lettres patentes Letters Patent (lrc partie) (l'art T) A.B.C.Cernent Inc.1983 Abattoir Ste-Claire ltée.1990 Abbey Sales Inc.1991 Admiral Securities Limited.1983 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, n° Il 2141 Lettres patentes Letters Patent (!\"\u2022 partie) (Part I) (suite) (continued) Agence de Gestion en Techniques de l'Eau (A.G.T.É.) ltée.1983 Agence John Fix ltée.1988 Ameublement Tropicana ltée.1983 Appareils d'Arrosage Ferma inc.1989 Ardecom inc.1983 Aubec Corporation.1983 Autobus Brisebois (1973) ltée (Les).1983 Autobus Roland inc.(Les).1983 Automobile Renault (St-Laurent) ltée.1983 Aviation Planning International Ltd.1983 B & O Plastic Industries Ltd.1983 Bamo inc.1983 Baron & Fils inc.1983 Bar-Salon L: Sorcier inc.1983 Bayer Electric Inc.1983 Berry ait Product* Lin ited.1983 Bijouterie André Marcl a :d inc.1983 Bijouterie B.Serko inc.1984 Bijouterie Lucien Larose inc.1984 Bombardier Credit Ltd.1985 Borg-Warner Credit Canada, Ltd.1984 Boritel Construction Ltd.1985 Bourcier Industries Inc.1984 Bourque (G.) & Associés inc.1984 Bourque & Bouchard Metal Inc.1984 Boutique de Chaussures La Belle inc.1984 Boutique Famor inc.1984 Boutique La Godasse inc.1984 Boutique Roanc inc.1984 Brassard (Roland) inc.1984 Brasserie des Remparts inc.1984 Brasserie Le Caucus inc.1984 Brisebois Bus Lines (1973) Ltd.1983 Brolek Corporation.1984 Brown & Gold Stables Inc.1986 C.A.Graphics Inc.1984 Calendar Investment Company Limited.1984 Canadian European Pastry Inc.1984 Cannonball Truck Rentals & Leasing (Québec) Ltd.1984 Cape Cod Fish & Lobster House Inc.1984 Capri Copy Service Inc.1984 Caron (André) Construction Inc.1985 Cascade Renovation Center Inc.1984 Cauchon (Léo) Construction Inc.1984 Central Vacuum Service Inc.1985 Centre d'Accueil Marie-Rivier inc.1984 Centre d'Éducation Canine CD.inc.1984 Centre de Plein Air aux Petits Mats inc.1984 Centre de Rénovation Cascade inc.1984 Centre du Pneu Upton inc.1984 Château Mirabelle inc.1985 Chaussures Cléo inc.1985 Chevrolet Duval inc.1985 Choquet Engraving Inc.1987 Cie des Exportateurs de Bétail Provincial ltée (La).1990 Cie Provincial dc Veau ltée (La).1990 Ciment A.B.C.inc.1983 Clinique La Renaissance inc.1985 Club de Chasse et Pêche Sisco inc.1985 Club de Placement Cercle inc.1985 Club de Vacances Ecovac inc.1985 Coffrage Fiiecau inc.1985 Coffrages Gebel inc.(Les).1985 Colobec Matching Ink Inc.1989 Compagnie de Portefeuille Isram inc.1988 Compagnie de Tapisserie et de Draperie Da- vid-Allan ltée.1986 Compagnie dc Tuiles du Québec inc.(La).1985 Compagnie Diversifiée Edelstein ltée (La).1985 Compagnie Villa du Saguenay-Lac-St-Jean inc.(La).1985 Conseiller en Personnel Joliette inc.1985 Conseiller & Services Techniques Biron inc.1985 Construction André Caron inc.1985 Construction BoriUl ltée.1985 Construction Boulogne inc.1985 Construction Gilbirt Bouclier inc.1985 Construction Léo Cauchon inc.1984 Construetio Gay & Carol inc.1987 Construction H.G.C.ltée.1985 Construe tio \\ M.G.Lirochellc inc.1988 Construction Nobel inc.1989 Construction Réal Gagné inc.1987 Construction Renaud et Roy inc.1985 Constructions C.L.R.Marcoux inc.(Les)- 1985 Constructions Claude Clément & Fils ltée.1985 Constructions J.L.R, ltée.1985 Constructions Leader(Québec) ltée (Les).1988 Continental Store (Barthurst) Ltd.1988 Corporation d'Administration d'Immeuble Mancor limitée (La).1985 Corporation Aubec.1983 Corporation de Gestion Klhara (La).1986 Corporation de Ventes Élan.1986 Corporation de Voyage Zizanis (La).1991 Crédit Bombardier liée.1985 Crédit Borg-Warner Canada, ltée.1984 D.& D.Carrière ltée.1985 D.Q.B.Distribution Inc.1986 Daneau (Gérald) inc.1986 Darius Gold Mines Inc.1986 David-Allan Wallpaper and Draperies Co.Ltd.1986 De Gaspé Parking Inc.1986 Dionysios Enterprises Inc.1986 Disques P.A.X.inc.1986 Distributeurs P & E inc.(Les).1986 Distribution Musantiqua inc.1989 Distributions D.Q.B.inc.(Les).1986 Distributions Juvenia inc.(Les).1986 Domaine Joie de Vivre inc.1986 Dombek inc.1986 Dumont (Armand) inc.1986 Duval Chevrolet Inc.1985 Dynam inc.1986 Ecovac Holiday Club Inc.1985 Écuries Brun & Or inc.(Les).1986 2142 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1(173.Vol.106, No.U Lettres patentes Letters Patent (lre partie) (Part /) (suite) (continued) Edelstein Diversified Co.Ltd.1985 Éditions du Haut-Yamaska inc.(Les).1986 Elan Sales Corp.1986 Elhara Management Corporation.1986 Empire Slacks Ltd.1986 Enlèvement de Rebus St-Laurent inc.1986 Entreprises Alcide Cousineau inc.(Les).1986 Entreprises Arthur Xadeau inc.(Les).1986 Entreprises Garget inc.(Les).1986 Entreprises de Construction Toupin inc.(Les) 1986 Entreprises Dyonysios inc.(Les).1986 Entreprises Électriques Bayer inc.(Les).1983 Entreprises L.L.Po-Mer inc.(Les).1986 Entreprises Lalancette & Fils ltée (Les).1986 Entreprises Sherville inc.(Les).1986 Entreprises Albert Trottier inc.(Les).1991 Équipement Électronique Côte Nord inc.1987 Équipements Carebo inc.(Les).1987 Est Service Québec inc.1987 Estrie Toyota inc.1987 Excavation Mirable ltée.1987 Excavations Vidolo limitée.1987 Fashion Mart Restaurant Limited.1987 Fenêtres de l'Est Victoriaville inc.(Les).1987 Ferme Gravel ltée.1987 Ferme Z.Dagenais inc.(La).1987 Feuille Métallique Rexway (Québec) limitée 1990 Filceau Form Inc.1985 Flex Investments Ltd.1987 Florathèques André Racourt inc.(Les).1987 Frechette (A.) & Associates Ltd.1987 Frechette (A.) & Associés ltée.1987 Gagné (Réal) Construction Inc.1987 Galeries Lessard Cap Rouge inc.(Les).1987 Gallagher (Leslie A.) ltée.1987 (iarage Diapolo inc.1987 Gebel Frame-Work Inc.1985 Gendron (Alcide) inc.1987 Gendron (Bert) & Associés inc.1987 Gerbeco inc.1987 Gilnix inc.1987 Graphiques C.A.inc.(I,es).1984 Gravure Choquet inc.1987 Groleau (G.) Industries Inc.1988 Groupement Forestier et Agricole de Beauce Sud inc.1987 Guy & Carol Construction Inc.1987 H.G.G.Construction Ltd.1985 H.L.B.Investments Ltd.1987 Home Smith Properties (Sherbrooke) Limited 1988 Hôtel Briand inc.1987 Ideal Crane Service Inc.1987 Immeubles Bourgeois-Hébert inc.1987 Immeubles Home Smith (Sherbrooke) limitée (Les).1988 Immeubles J.M.Body inc.(Les).1988 Immeubles Jenkins & Arsenault inc.1988 Immeubles Landmark ltée (Les).1988 Immeubles Payette & l'Heureux inc.(Les).1988 Industries Bourcier inc.1984 Industries du Plastique B & O ltée (Les).1983 Industries G.Groleau inc.(Les).1988 Installations Électriques Leclerc inc.(Les).1988 Institut de Recherches pour l'Éducation du Futur du Québec inc.(L').1988 Investissements J.M.L.inc.1988 Isabelle Shops Ltd.1988 Isram Holding Co.Inc.1988 J.& B.Furniture Transport Québec Inc.1988 Jardins Pondev ltée (Les).1988 Jenkins & Arsenault Realties Inc.1988 Jett-R Sandblasting Inc.1989 John Fix Agency Ltd.1988 Laboratoire d'Optique Éclair inc.1988 Laboratoires Prop ltée.1988 Lamothe Tire Casing Inc.v.198S Landmark Properties Ltd.1988 Larose (Roger) inc.198S Leader Construction (Québec) Ltd.1988 Leclerc Electric Inc.1988 Litek inc.1988 Location de Camions Cannonball (Québec) ltée.1984 Luto me.1988 M.G.M.Programming Inc.1990 M.G.Larochelle Construction Inc.1988 Maçonnerie Longueuil inc.1988 Magasin Continental (Bathurst) ltée.1988 Magister Mining Corporation Limited.1989 Mai Tai Restaurant Inc.1989 Mailloux (Victor) inc.1989 Maison du Poisson & Homard Cape Cod inc.(La).1984 Maison Funéraire Trudel inc.1989 Maisons de Commerce Isabelle ltée (Les).1988 Maisons Mobiles Waterloo inc.1989 Maisons Quebco inc.(Les).1989 Maisons R.Julien inc.(Les).1989 Mancor Property Management Corporation Limited.1985 Marché Alphonse Ouellet inc.1989 Marojo Sales Inc.1989 Mélange d'Encre Colobec inc.1989 Mertl & Dain Limited.1989 Mertl & Dain limitée.1989 Métal Bourque & Bouchard inc.1984 Michaud & Larue inc.1989 Mines d'Or Darius inc.(Les).1986 Mirpos inc.1989 Modes Ting-a-Ling inc.(I^es).1991 Musantiqua Distribution Inc.1989 Nettoyage au Jet de Sable Jett-R inc.1989 Nobel Construction Inc.1989 Opsis inc.1989 P & E Distributors Inc.1986 Pantalons Empire ltée (Les).1986 Papeteries P.M.inc.(Les).1989 Parc d'Amusement de l'Estrie inc.1989 Pash (Maurice) Limited.1989 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1973, 105' année, «\u2022 IL 2143 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part I) (suite) (continued) Pasli (Maurice) limitée.1989 Pâtisserie Canadienne Européenne inc.(La).1984 Perfora tec inc.1989 Perma Sprinklers Inc.1989 Photocopie F.B.E.inc.1989 Photographie P.D.C.inc.1989 Pizza Sam Chantons en Choeur inc.1990 Place Deschênes Limited.1989 Place Deschênes limitée.1989 Placements du Havre ltée (I,es).1989 Placements Flex ltée (Les).1987 Placements H.L.B.ltée.1987 Placements Jeton Bleu inc.(Les).1989 Placements Le Barrage inc.(Les).1990 Placements Le Filtre inc.(Les).1990 Placements W.R.Little inc.(Les).1991 Planification Internationale en Aviation ltée .1983 Plomberie Beauport inc.1990 Pneus Lamothe inc.1988 Pondcv Gardens Ltd.1988 Productions Michel Des Rochers inc.(Les) .1990 Produits Berryfast limitée (Les).1983 Produits de Caoutchouc M.B.inc.1990 Produits Tortan ltée (Les).1991 Programmation M.G.N.inc.1990 Promotions Propop inc.1990 Prop Laboratories Ltd.1988 Provincial Livestock Exporters Co.Ltd.1990 Provincial Veal Co.Ltd.1990 Québco Houses Inc.1989 Québec Sauna Inc.1990 Rampart Brewery Inc.1984 Renault Automobile (St.Laurent) Ltd.1983 Rermcx Canada Ltd.1990 Rennex Canada ltée.1990 Restaurant Étoile Wong inc.1991 Restaurant Les Chenets inc.1990 Restaurant Mai Tai inc.1989 Restaurant Mode Mart limitée.1987 Restaurant Perfecta de Joliette inc.1990 Restaurants Marie-Victorin inc.(Les).1990 Revue Nature inc.1990 Rexway Sheet Metal (Québec) Limited.1990 Rosen (Harold C.) inc.1990 Roy (J.Emile) & Fils inc.1990 S.F.S.Specialized Forest Services Ltd.1990 Ste-Claire Abattoir Ltd.1990 St-Laurent Garbage Removal Inc.1986 Salaison Valleyfield inc.1990 Sauna Québec inc.1990 Sécurité Lenet ltée.1990 Sedifinc.1990 Service Central de Réservoirs inc.1985 Service de Copie Capri inc.1984 Service de Grue Idéal inc.1987 Service de Vente Moderne inc.1990 Services Forestiers Spécialisés S.F.S.ltée.1990 Siegler (Nat) inc.1990 Sing Along Sam Pizza Inc.1990 Société d'Aqueduc d'Allen's Mill ltée.1990 Société de Promotions V.T.T.inc.1990 Société d'Investissements Calendrier limitée .1984 Société Minière Magister limitée.1989 Société Philuc inc.(La).1990 Station de Ski Vallée Pruneau inc.1991 Stationnement de Gaspé inc.1986 Stéréo Saint-François inc.1990 Techniques Éducatives M.C.R.V.L.inc.1991 Therrien (A.& P.) inc.1991 Ting-a-Ling Fashions Inc.1991 Tortan Products Ltd.1991 Transport Adrien Champagne & Fils inc.1991 Transport d'Ameublement J.& B.Québec inc.1988 Transport Paul Néron inc.1991 Trebor (Amérique du Nord) ltée.1991 Trebor (North America) Ltd.1991 Tropicana Furniture Ltd.1983 Trottier (Albert) Enterprises Inc.1991 Upton Tire Centre Inc.1984 Valeurs Mobilières Amiral limitée (Les).1983 Ventes Abbatiales inc.(Les).1991 Ventes Marojo inc.(Les).1989 Vidolo Excavation Limited.1987 Villeneuve & Choinière inc.1991 W.R.Little Holdings Inc.1991 Wong's Star Restaurant Inc.1991 Woodhaven (Québec) ltée.1991 Zizanis Travel Corp.1991 Lettres patentes letters Patent (3e partie) (Part III) Aide à l'Enfance Inadaptée de l'Est de Montréal (L').1991 Alexander the Great Brotherhood of Eastern Macedonia (The).1991 Association des Bienfaiteurs de Ste-Anne de Cantalupo.1992 Association des Commerçants Place La Seigneurie inc.1992 Association des Marchands dc Place Pointeaux-Trembles inc.(L').1992 Association des Orthoptistes du Québec.1992 Association des Trappeurs des Cantons de l'Est inc.1992 Association Québécoise des Artistes de la Danse inc.1992 Ateliers du Godendard inc.(Les).1992 Blomar inc.1992 (\"amp Gatineau inc.1992 Centre de Bénévolat de Cowansville.1992 Club Auto-Neige des 47 inc.1992 Club de Hockey Les Aigles de St-Bernard inc.(I-c).1992 Club de l'Âge d'Or de Dubuisson (Le).1992 Club de l'Âge d'Or de Ste-Dorothée.1992 Club de l'Âge de St-Félicien.1992 Club de Motoneige Arvida inc.2018 Club de Moto-Neige Hemmingford inc.1992 2144 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Avril 7, 1973, Vol.105, No.11 Lettre* patentes Letters Patent (3* partie) (Part UP) (suite) (continued) Club «le Moto-Xeige I«es Gais Campagnards de Heauharnois inc.(Le).1992 Club de Moto-Xeige Mont-Laurier inc.1992 Club de Moto-Xeige Poltimore.1993 Chlb de Natation Jonquièrc-Kénogami inc\u2014 1992 Club de Ski Mont Citadelle inc.1992 Club des Retraités de Price inc.(l>e).1992 Club Sportif Le Plateau du Parc inc.1992 Club Sportif Les Franc-Xord Macazicns inc.1992 Club Sportif Pocomoco inc.1992 Comité des Loisirs de Montcbello inc.1992 Corporation de l'Aréna de Cap (\"bat inc.(La).1992 Corporation du Musée du Saguenay inc.(La).1992 Cowansville Volunteer Sendee Centre.1992 École Secondaire Montaigne inc.(L').1992 Fraternité de la Macedonie de l'Est Alexandre le Grand.1991 Garderie Hubertubcrlu (La).1992 Hemmingford Snow-Mobilc Club Inc.1992 Institut de Recherches Didactiques de Laval inc.1993 Ledpo inc.1993 Montreal Health Press.1993 Place Pointe-aux-Trembles Merchants Association Inc.1990 Poltimore Snow Mobile Club.1993 Presses de la Santé de Montréal (I*s).1993 Salon dc la Femme du Québec inc.1993 Service de Ixusirs pour Personnes Retraitées de Montréal.1993 Service des Loisirs de la Cathédrale de Montréal.1993 Société des Éditions Populaires de l'Outaouais 1993 Télévision Communautaire La Pocatière inc.1993 Lettres patentes, Letters Patent, avis d'annulation Notice of annulment (1er avis) (1st notice) Borsa Investment Inc.1997 Crémerie Calderone inc.1997 Crémerie Stella inc.1997 Deltro Construction Inc.1997 Entreprises Samo inc.1997 Guva Painters Limited.1997 North Landscaping, Inc.1997 Voyageur inc.1997 Lettres patentes, Letters Patent, avis de correction Notice of correction Entreprises Salice inc.(Les).1997 Lettres patentes Letters patent supplémentaires Supplementary-Action Sociale, limitée (L').1993 Auto Forum inc.1993 Best Service People Limited.1993 Bigras & Vaillancourt inc.1993 Blondeau ((lilies) et Compagnie.1993 Boisvert (Orner) & Ass.inc.1993 Boulangerie Blé d'Or inc.1993 Boutique Le Faubourg inc.1994 Bulger (Murray G.) & Associés (Québec) ltée.1994 Canadian Broadloom (Québec) Ltd.1994 Canadian Chinese Cultural Society of Montréal Inc.1996 Carrier (Michel) inc.1994 Club Récréatif des Loisirs Acadiens de Beauharnois inc.1994 Club Social Colonial inc.1994 Collège Français (1965) inc.(Le).1994 Collin & Associés inc.1994 Colonial Social Club Inc.1994 Compagnie de Fourrure & Cuir Pacifique Inc.1995 Copacabana Café inc.1994 Dévelop|>ement M.L.limitée.1994 Doma inc.1994 Domaine du Verger inc.(I*).1994 Dumco Métal Products Co.Ltd.1994 Fabricants des Toits de Vinyle du Québec inc.(1-es).1994 Forum Auto Inc.1993 Gagnon Frères Nouveautés (Pot-Alfred) ltée.1994 Galeries Mégantic inc.(Les).1995 Galeries Richelieu inc.(Les).1995 Grand Union Finance Corp.(The).1995 Huron Footwear (1968) Inc.1995 Industrial Fasteners Ltd.1995 Industries Chenard inc.(I.*s).1995 Industries du Fil J.C.N, ltée (I,cs).1995 Institut Val-du-I-ac inc.1995 J.C.N.Wire Industries Ltd.1995 Jardins Su-C'asa inc.1995 Jolen Holdings Ltd.1995 Kwikasair Ltd.1995 Laminex Structures Ltd.1996 Lavigne (Claude) inc.1995 Lavigucur Auto Inc.1995 Location Pinard inc.1995 M.L.Development Limited.1994 Micro-Cinema Society Ltd.1996 Miller Holdings Ltd.1995 Morgan Stanley Canada Limited.1995 Morgan Stanley Canada limitée.1995 Pacific Fur & Lather Co.Inc.1995 Paquet (Louis Ph.) inc.1996 Pavillon de Beauharnois inc.(I.*).1996 Pinard leasing Inc.1995 Place Montréal inc.1996 Productions Roger Garand inc.(Les).1996 Rousson inc.(Le).1996 Société Canadienne de Culture Chinoise de Montréal inc.(La).1996 Société d'Administration Immobilière Le Gar- deurinc.(La).1996 Société Micro-Cinéma ltée.1996 Soucy-Mercury (Ventes & Services) ltée.1996 Structures Laminex ltée.1996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1973.10ô< année, u° lk 2145 Lettres patentes supplémentaires (suite) Letters Patent supplementary (continued) Tanni International Ltd.1990 Tan ni International ltée.1990 Tan/.er Industries Ltd.1996 Unity Realty Holdings Limited.1996 Vulcanisation St Laurent (1970) ltée.1996 Letters patent Supplemen tary Notice of correction Just Equipment & Supply Co.(1963) Limited.1998 Lettres patentes supplemen taires avis dc correction Sieges sociaux Head Offices Agence Centrale de Sécurité limitée.2000 Bamo inc.2008 Better Made Shoulder Straps Inc.2008 Bombardier Credit Ltd.2009 Brassard (J.P.) Inc.2009 Central Security Agency Limited.2006 Chamex inc.; .2005 Comité du Centenaire de Baie-des-Sables inc.200!) Concorde Electric Limited.2006 Concorde Électrique limitée.2006 Crédit BombarJier ltée.2009 Crown Holdings Ltd.2011 D.Q.B.Distribution Inc.2006 Daraco inc.2009 Distributions D.Q.B.Inc.(Les).2006 Doucet (L.) liée.2008 Ferme Avicole Stc-Maric inc.2008 Frigon Ice Inc.2007 Glace Frigon inc.2007 Greater York Group Ltd.2007 Groupe Grand York ltée (Le).2007 Investissements Piedmont ltée.2010 Labo.S.M.Inc.2011 Lambert-Starke Products Corp.2010 Matério inc.2010 Perspective G.R.S.Haut Richelieu inc 2007 Piedmont Investments Ltd.2010 Productions du Verseau inc.(Les).2010 Sauna Neptune inc.2006 Société Industrielle et Minière du Nord-Ouest Québécci< limitée (SIMNOQ) (La).2008 Sovac ltée.2007 Texpro Inc.2006 Tremblay (J.Roger) limitée.2011 DEMANDES A LA LÉGISLATURE APPLICATIONS TO LEGISLATURE Club de Golf New Glasgow (1966) inc.2016 Commander Nickel Copper Mines Ltd.2016 Sainte-Foy, ville-city.2016 LIQUIDATION DES COMPAGNIES Loi de la WINDING-UP ACT Association coopérative des pêcheurs de Ste-Thérèse.2039 Brothers, Aronoff (Nomination d'un liquidateur-Appoint ment of liquidator).2039 MIN 1ST ÈR ES DEI'A R TMENTS Affaires municipales Municipal Affairs St-Georges-Ouest-\\Yest, ville-town (Annex.).2054 Institutions Financial financières, Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurance: Insurance: Granite State Insurance Company (Annul.).2038 Insmor Compagnie d'Assurance d'hypothèque (Permis).2039 Insmor Mortgage Insurance Company (License) .2039 National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh.PA.(Annul.).2037 Souveraine, Compagnie d'Assurance d hypothèques (La) (Permis).2038 Sovereign Mortgage Insurance Company (The) (License).2038 Terres et forêts Lands anil Forests Cadastre: Cadastre: Pointe-Gatineau, village.2056 Robinson, canton-township.2055 Sainte-Agathe-des-Monts.par.2056 Saint-Augustin, par.2055 Saint-Jérôme, village.2056 Sainte-Thérèse-des-Moiits.par.2056 Saint-Vinccnt-dc-Paul.par.2056 NOMINATIONS APPOINTMENTS Conseils en loi Queen's Counsel de la reine: learned in the laie: Benoit, Claude.2019 Bergeron.Pierre.2019 Charette, Huguctle-M.2019 Drouin.Richard.2019 Duchesneau, Jules.2019 Gilbert, Guy.2019 Gomery, John II.2019 Haljierin, Irving J.2019 Jolin, Louis.2019 Kravet/., Dov.2019 Lasnier.Bernard.2019 Laurence, André.2019 Leavitt.Jules.2019 L'Heureux.Jean-Jacques.2019 Maillonx, Paul.2019 Mongeau, Jacques.2019 Poitras, Lawrence-A.2019 Rousseau, J.-Pierre.2019 Rioux.Michcl-E.2019 Rivard.Lomer.2019 Verdy, Pierre.2019 Zaor, Dewey.2019 2146 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1973, Vol.105, No.Ii Divers: M iscellaneons.Bouchard, Louis-Philippe (Juge de la Cour provinciale-Jtulge of Ihe Provincial Court) .2021 Dcschamps, Jean (Délégué général-Delegale general).2020 I hirnainc, Michel (Juge de ta Cour provinciale\u2014 .1 udge of the Provincial ( 'oiirl).2021 Founder, Jean (Délégué général Delegate general).2020 Leblanc, Pierre (Coroner).2022 l'oliquin, ( in v (Délégué général-Delegale general).2020 Prévost, Adolphe (Juge de la Cour prorinciale- ¦I udge of the Provincial Court).2021 Présidents d'élection: Relurning-officers: Bonneville, Robert (Abitibi-Est).2020 M icliaud, André (Rimouski).2020 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Coming into force of the olhcial cadastre of a part of the village of Aylmer, situated in the registration division of Calincau.2023 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Brest, situated in the registration division of Sept-lles.2024 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Brest, situated in the registration division of Sept-îles.2034 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of (iodmanchester, situated in the registration division of Huntingdon (Erratum).2138 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Laflèche, situated in the registration division of Saguenay.2026 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Laflèche.situated in the registration division of Saguenay.2027 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Phélypeaux, situated in the registration division of Sept-lles.2029 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Reclus, situated in the registration division of Témiscamingue.2031 Coming into force of the official cadastre of a part of the parish of St.John, situated in the registration division of St.John.2032 Coming into force of the official cadastre of a part of the parish of St.John, situated in the registration division of St.John.2035 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du village d'Aylmer.située dans la division d'enregistrement dc Gatineau.2023 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Brest, située dans la division d'enregistrement de Sept-lles.2024 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Brest, située dans la division d'enregistrement de Sept-lles.2034 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de (iodmanchester, situé dans la division «l'enregistrement de Huntingdon (Erratum).2138 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Laflèche, située dans la division d'enregistrement de Saguenay.2026 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Laflèche, située dans la division d'enregistrement de Saguenay.2027 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Phélypeaux.située dans la division d'enregistrement de Sept-îles.2029 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une par-tic du canton de Reclus, située dans la division d'enregistrement de Témiscamingue .2031 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie de la paroisse de Saint-Jean située dans la division d'enregistrement de Saint-Jean .2032 Mise en vigueur «lu cadastre officiel d'une partie de la paroisse de Saint-Jean, située dans la division d'enregistrement de Saint-Jean,.2035 Régie dc l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board Professioncls désengagés.2051 Professionals withdrawn.2051 Régie des marchés Québec Agricultural agricoles du Québec Marketing Board The Portneuf County Whole Milk Producers' Joint Plan (Appointment of aliquidator).2116 Plan conjoint des producteurs de lait nature du comte de Portneuf (Nomination d'un liquidateur).2116 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATION ACT Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: Agence Fleur de Lys inc.(L').2040 Alliance Produits de Beauté inc.(L').2040 Assomption gaz & pétrole ltée (L').2040 Assomption Holdings Corp.(L').2040 Auberge du Grand Métis ltée (L').2040 Bombardier (Jean-Luc) inc.2040 Bonnor (Jean) charpente d'acier inc.2040 Boutique des fleurs Lasalle inc.(La).2040 Boutique du connaisseur inc.(La).2040 Calèche Motel-Hôtel inc.(La).2040 Caverne inc.(La).2040 Centrale d'ambulances inc.(La).2040 Chevalerie St-Sauveur inc.(La).2040 Cie Apyc ltée (La).2040 Cie Beaugeste ltée (La).2040 Cie d'asphalte J.Harris Lauzon ltée (La).2040 Cie d'entretien Laurentide ltée (La).2040 Cie d'habitation Roland inc.(La).2040 Cic d'imi>erméabilisation de Québec ltée (La).2040 GAZETTE OFFICIELLE DC Ql'f.BEC.7 avril 107.1.Wr,- année.1), 2147 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Cie du Domaine Belgo-Québec (La).2040 Cie Georges Cauchon liée (La).2040 Cie Revetex dc Québec inc.(La).2040 Cie Swatson-Livet Ltd.(La).2040 Compagnie Douville inc.(La).2041 Compagnie Lyrique métropolitaine inc.(La).2041 Condominium Corporation (The).2041 Coupole des Gastronomes inc.(La).2041 Cour à Lois et scierie Perkins ltée (La).2041 Country Inn Inc.(The).2041 Dandurand (Grégoire) inc.2041 Discothèque Mont Ste-Anne inc.(La).2041 Fontaine ltée.2041 Fortin Appliance Service Inc.2041 Foster Sand and Gravel Ltd.2041 Fount Inc.2041 Four Seasons Mohile Home Ltd.2041 Franchine Equipment Service Inc.2041 Francis Development Corp.2041 Frank-N-Stein Franchises Ltd.2041 Frontenac Billard inc.2041 (J.& It.Realties Inc.2041 G.& G.Lingerie inc.2041 G.& L.Sport Wear Inc.2041 G-Co limitée.2011 Gahtony con: itruction ltée.2041 Gagnon automobile (Magog) limitée.2041 (îalerie du siècle inc.(La).2041 Galica incorporée.2041 Garage Himbeault ltée.2041 Garage Lucien Amyot inc.2041 Garage St-Adolphe inc.2041 Garage St-.lean (1964) inc.2041 Gasconv Investments Ltd.20-11 Gasslnc.2041 Gem Taxi Corp.2041 Geralco Investment Inc.2041 Gerald Investment Corp.2041 Geri'a Inc.2042 Gerjac Inc.2042 Gestion Talleyrand inc.2042 Geva Corp.Ltd.2042 Gino Liberia Landscaping Inc.2042 Gino Restaurant ltée.2042 Giroux (Henri) inc.2042 Glamour Services Ltd.2042 (ilenrae Realties Limited.2042 Go-Kart City Inc.2042 < ii id: ii- Construction Inc.2042 Godbout et associés inc.2042 Goldor Inc.2042 Golf way Corporation.2042 Goodies Products of Canada Inc.2042 Gourmet Cartierville inc.2042 Graffic Productions Services Ltd.2042 Grand Prix Model Raceways Ltd.2042 Great Montreal Press Inc.(The).2042 Grondin (Jean-Paul) ltée.2042 Grosvenor Development Inc.2042 (iuérette Service Station Inc.2012 Guests & Events Identification Ltd.2012 Guild Industries Ltd.2042 H.M.Electronic Inc.2042 Habitant Gas ft Oil Limited.2042 Hairco Corporation.2042 Halcarltée.2042 Haldcu Property Management Ltd.2042 Hamoniaux & Bélanger inc.2042 Hargold Cleaners Ltd.2042 Harrison Industries Co.Ltd.2042 Helen's Hotels-Motels Ine.2012 Hi line Originals lue.2042 Hemisphere Investment Services Ltd.2043 Héueau (Irenée) inc.2044 Heraclitus Corp.2043 Hillmack Services Ltd.2043 Hispania Products Inc.2043 Holiday Health Studio Inc.2043 Holland Electrical Supply Ltd.2043 Holland Equipment & Machinery Co.Ltd .2013 Home Family Discount Sales Inc.2043 Home-Freez Provisioners Inc.2043 Hôpital d'Autos inc.2043 Hostellcrie du Grand Cerf inc.2043 Hôtel du Toil Bleu inc.2043 Hôtel la Nouvelle-France inc.2043 Hôtel Lachapellc liée.2043 Hôtel Larose ltée.2043 Hôtel Laval de Chicoutimi inc.2043 Hôtel Manoir Louise inc.2043 Hôtel-Motel Canari inc.2043 House of Sports Ltd.2043 Hugo Creations Inc.2043 Hydromalnc.2043 I.P.C.Pictures Corp.2043 Ideal Home Products Inc.2043 Ideal Yachting & Sporting Club (1965) Inc.2043 Idées Inc.2043 Idlewild Stable Inc.2043 He dc France Seafood Restaurant.2043 Immeubles Deux-Rives inc.2043 Imperia Lumber (Montreal) Ltd.2043 Imperial Land Holding Ltd.2043 Imprimerie artistique inc.2043 Independent Florist s Corporation.2043 Industrial Claims & Adjustment Bureau Ltd.2043 Industrial Tank Cleaners Ltd.2043 Industries Roby Ir.c.-.2044 Institut d'évaluation scientifique inc.2044 Institut dc la Tour inc.2044 Institut Gilain inc.- .2044 Institut Professiom cl International inc.2044 Institut universel de cours par correspondance inc.2044 Institut Volonté inc.2044 Inter City Motors Ltd.2044 Intercontinental Business Consultants Inc .2044 Intercontinental Imiiort & Export Inc.2044 Intermezzo Music Shop Inc.2044 QVfi.BF.C OFFICIAI.CA7.F.TTE.April 7, 197.3, Vol.105, So.1A Avis ilr ill.'soluiion Notice of Eventual éventuelle de Corporation*: Dissolution of Corporations: {suite) (continued) International Business Backers Inc.2044 International Data Processing Inst (Québec) Ltd.2044 International Educational Sales Promotion Consultants Inc.2044 International Motor Exchange Inc.2044 International Sulphur & Mining Ltd.2044 Invesl-llive Realties Ltd.2044 Investment Planning Services of Québec Inc.2044 IsrosLtd.2044 .1.& K.Air Conditioning Ltd.2044 Jacques & Bélanger Transport ltée.2044 Jadran Construction Co.Inc.2044 Jamaica Homes (Que) Ltd.2044 .lanripas Inc.2044 .lav Bee Management & Consultants Ltd.2044 Jayliar Mines Ltd.2044 Jeangilou inc.2044 Jean-Paul Purs Inc.2044 Jean Talon Butchers Simply Inc.2044 Jet Snack Bar Inc.2041 Jet Trading Corp.2044 Jette & Lapierre inc.2044 Jiger Outfitters Inc.2045 Jodoin's Westmount Cartage Ltd.2045 .lonken Industries (Quebec) Ltd.2045 Joyaux et Artisanat du monde ltée.2045 Juïi Originals Inc.2045 Julien (Henri) Auto Body Inc.2045 Julot(L.)Inc.2045 Jupiter Film Products Ltd.2045 Kane Construction Inc.2045 Kartodromes ltée (I.es).2045 Kasu Investment Corp.2045 Kathleen Investment Inc.2045 Kénogami Drive Yourself Inc.2045 Kensington Moly Mining Co.Ltd.2045 Kenson Limited.2045 Kent Bakerv & Pastry Products Inc.2045 Kent Photo-Supplies Ltd.2045 Kerry's Auto Repair Ltd.2045 Key Distributors Ltd.2045 Kinkord Development Corp.2045 Kitchener Realty Corp.2045 Klug Precision fool Works Co.Ltd.2045 Komak Land Holdings Ltd.2045 Koodlik Québec Mines Limited.2045 L.& M.Homes Inc.2045 L.A.C.Construction Inc.2045 L.L.B.Inc.2045 L.M.Service ltée.2045 Ferland (L.P.) & Fils inc.2045 Langlais (Ignace) limitée.2045 Larkin Realty Corp.(The).2045 Legal Insurance Directory Inc.(The).2045 Lussier (Jean) inc.2045 Maison répare-tout inc.(La).2045 Malouine inc.(La).2046 Mode textile ltée (La).2016 Moreau (II.) transport liée.2046 Only Caféine.(The).2046 Petite (irange Steak House Inc.(La).2046 Poulin (Cilles) limitée.2046 Quincaillerie Louis Rousseau inc.(La).2046 Rôtisserie Côte des Xeiges inc.(La).2046 Route 1 Journal Publishing & Printing Company Inc.(The).2046 Salon Embassy Inc.2046 Sayard auto (Victoriaville) ltée.2046 Scierie de la Rivière Portneuf inc.(La).2046 Seagull Corp.2046 Scatac Enterprises Ltd.2046 Selects automobile limitée.2046 Sema Enterprises Inc.2046 Sept-îles Drive Yourself Inc.2046 Sept îles Landscaping Inc.2046 Sérigraphie artistique inc.2046 Service avicole d'H>erville inc.20-16 Service de sécurité Sherbrooke inc.2046 Shcahan Corporation Ltd.2046 Si-Ma Construct ion Inc.2046 Sicotte électrique inc.2046 Sig-Xe limitée.2046 Sildcel Ltd.2046 Silhouette Health Studio of Lachine Ltd.2046 Simsil Mines Inc.2046 Ski Wear Contractors Inc.2046 Socar Compost (Québec) Inc.2046 Société Charron inc.2046 Société d'entreprise générale de Guyenne ltée (La).2046 Société d'entreprises St-.Iude inc.(La).2046 Société d'épuration du Québec inc.(La).2046 Société de distribution Film Canada inc.(La) 2047 Société de gestion Saguenay ltée (La).2047 Société de gestion des tabacs ltée (La).2047 Société de placements Perreault ltée (La).2047 Société Delin ltée (La).2047 Société internationale de construction rénovation ltée (La).2047 Soldex Investments Inc.2047 South Lawrence Mining Corp.2047 Sou t h gate Corporation.2047 Special Advanced Concepts Inc.2047 Spot Realties Inc.2047 St-Vincent construction inc.2047 Stanford's Appliances Ltd.2047 Stationnement St-Hubert Parking Inc.2047 Stockade Inc.2047 Sunlight Construction Corp.2047 Sunset Motel Inc.2047 Super-Marché Pa-Jo inc.2047 Super Meat Products Inc.2047 Superior Building Maintenance Ltd.2047 Supreme Discount House Inc.2047 Supreme Mines Ltd.2047 Sussex Candy Co.Ltd.2047 Swiss Nursery Ltd.2047 Sydmor Investments Ltd.2047 2149 Avis dedissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: ' (suite) (continued) Szabo's Service Station Inc.2047 T.C.S.Oil Heating Services Inc.2047 Ï.O.F.Personnel Inc.2047 T.P.G.construction ltée.2047 Tailleur Chic ltée.2047 Taurus Films Inc.2047 Taverne Champlain inc.2047 Technocon Inc.2047 Tecon Corp.2047 Tee-Pee Bowling Inc.2048 Tele Imex Ltd.2048 Tele-Art Films Ltd.2048 .Télé-Publicité (Montréal) inc.2048 Telecolo Inc.2048 Television Cable Inc.2048 Témiscamingue Electric Inc.2048 Temporel Inc.2048 TenbecCorp.2048 Terra Nova Grocery and Meat Market Ltd.2048 Texas Kidd Mining Corp.Ltd.2048 ' TexpertsLtd.2048 \"The Citizen\" Construction Co.Ltd.2048 Theatre Centre inc.2048 Thermos Québec inc.2048 ' Therrien ltée.2048 Thirty-One Forty Maplewood Corp.2048 « Thor Basement Water Proofing Co.Inc.2048 Thosim Holdings Ltd.2048 Tounnik Inc.2048 Tower Provisions Inc.2048 Trailco Corp.2048 Trans-Canada Air Photo Inc.2048 Trans Continental Adjustment Ltd.2048 Trans Island Landscaping Ltd.2048 Trans-Canada Thread Co.Ltd.2048 TrànsexLtd.2048 '(.Transport de la Rive Sud ltée.2048 Travel Magazine Ltd.2048 Tremblant Development Corp.2048 Tremblay & Vallé ltée.2048 Tremblay construction inc.2048 Triangle Precast Concrete Ltd.2048 Trident Construction Co.Ltd.2049 Trident Corporation Ltd.(The).2049 Trinidad and Tobago (Montreal) Association (The).T.2049 Tropico Inc.2049 Tupper Enterprises Inc.2049 Twentieth Century Products Inc.2049 Typewriter City Inc.2049 Ungava Transit (Baie-Comeau) Ltd.2049 Unifilm Inc.2049 Uniform World and Sportswear Centee Inc.2049 Union Travel Ltd.2049 United Equities Corp.Ltd.2049 Upstairs Apparel Inc.2049 Urbatec Investments Inc.2049 V.K.Charm Knitting Mills Ltd.2049 Van's Travel Consulting Service Inc.2049 Vanguard Industries Ltd.2049 Varel Inc.2049 Ventura Enterprises Ltd.2049 Venus Company Ltd.2049 Verdun Beauty Bar Ltd.2049 Veraicoltée.2049 Versatile Industrial Products Ltd.2049 Vézina (H.) & Fib inc.2049 Viau Rambler Ltd.2049 Viberco Inc.2049 Vic Picture Frames Ltd.2049 Victoria Nursing Home Inc.2049 Vil-Co Aluminium ltée.2049 Village Bowl Inc.(The).2049 Village familiaj inc.2049 Ville-Marie Shopping Centre Inc.2049 Vincent (Julien) Transport Inc.2050 Viscount Metal Products (Québec) Ltd.2050 Visualnc.2050 Vitrerie Drouin inc.2050 Voyages Sélectifs inc.2050 Ward Design & Print Services Ltd.2050 Webster Realties Co.Inc.2050 West Island Promotions Ltd.2050 Westminster Printing Corporation.2050 Westview Apartments Inc.2050 White Rose Cleaners & Shirt Ijiunderers Inc.2050 Woburn Lumber Ltd.2050 Young Construction Ltd.2050 Young Favorite Inc.2050 Zenith Sales Corporation.2050 Révocation de dissolution: Revocation of dissolution: Diamond Investment Corporation.2050 Imperial Gardens Inc.2050 Prêt d'Honneur de l'École Supérieure St-Georges d'Iberville Inc.2050 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Beauport, ville-city.2102 Des Ilets, c.s.-s.b.2112 Dollard-des-Ormeaux, c.s.-s.b.2108 LaSalle, cité-city.2106 Rock Forest, munie.2104 Saint-Jean-Chrysostôme, ville-town.2109 Templeton, village.2100 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Association de la Construction dc la Mauricie inc.(Nom-Name ch.).2113 Association des employés de Bertrand Croft inc.F.C.A.I.(Siège social-IIead office).2113 Association des Employés de Peerless Clothing (L') (Exit, term).2114 National Union of Lionoleum Workers of Montreal Inc.(Exist.Term).2114 2150 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 7, 1978, Vol.105, No,n,\\ SYNDICATS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL SYNDICATES (.suite) (continued) Peerless Clothing Employees Association (Exist, term).2114 Syndicat des Producteurs de Betteraves à.Sucre de la Région de Joliette (Exist, term) 2114 Syndicat des Travailleurs du Linoleum de Montréal inc.(Le) (Exist, term).2114 VENTES SALES Liciiaiion .Licitation Fédéral Construction Limited vs Rabicew (Succession-Estate).2117 Olescliuk et al.vs Oleschuk.2118 Par Shérifs By Sheriffs Beauce Beauce Saint-Prosper, mun.vs Boulet.2119 Hauterive Hauterive Dion vs Maltais.2119 Montréal Montreal Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Forest.2120 Banque Royale du Canada (La) vs Tuson.2123 Brizard et ai.vs Bouchard et of.2121 Caisse Populaire St-Claude vs Jeolle.2122 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Forest.2120 Royal Bank of Canada (The) es Tuson.2123 Schaefer (Joel) vs Weltman.2122 Valtes inc.vs T.S.D.Construction inc.2123 Québec w,':V/ty .Qltfkec Beauport, villé-city vs Boudreau .'.i.2125 .Beauport, ville-city vs Côté.
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.