Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 novembre 1973, Partie 1 samedi 10 (no 45)
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE 10 NOVEMBRE 1973 N° 45 6559 PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFF TCTELLE DU QUEBEC, 10 novembre 1973.105' année, n' 1,5 6561 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce.afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai Publieher 6562 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.1,6 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec.25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1) : from 1 January to 31 December, $20; from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazelle, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 106' année, n° 45 6563 AVIS JURIDIQUES Renseignements sur les compagnies Avis de dissolution éventuelle de corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.Nom de la compagnie Name of the company L'ACADEMIE DE MEDECINE SPORTIVE DU QUEBEC ACROPOLE FURNITURE CO.LTD.AGENCE D'ASSURANCE LAFONTAINE LTEE.AGENCE IMMOBILIERE DU LAC CONNELLY INC.AGENCE DE RECLAMATIONS J.D.INC.LES AGENCES LAD INC.ALPHA PHOTO 4 COINS INC.JURIDICAL NOTICES Companies Information Act Notice of Eventual Dissolution of Corporations The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St«-Foy.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.8t-Hyppolyte.1970, 1971 et/and 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1972 et/and 1973 1970 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1963 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1972 et/and 1973 1971 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1964, 1970 à/to 1973 incl.1961, 1971 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.AMENAGEMENT COLOMBAY LTEE.St-Colomban.LES AMENAGEMENTS OLIDAR INC.Brossard.AMEUBLEMENT DU BUCHERON INC.Montréal.AMEUBLEMENT CLAUDE INC.Jacques-Cartier.APEX WIRE PRODUCTS LTD.Montreal.APOLLO DEVELOPMENT CORP.Montréal.APOLLO ELECTRIC LTD.Montreal.APOLLO VENDING MACHINES INC.Laval.APPALACHES AUTOMOBILE CLUB.Richmond.APPIA CONSTRUCTION INC.Montreal.AQUA MAINTENANCE INC.Montreal.AQUA PEDIC CORP.Montreal.AQUARIUS CREATIVE BOUTIQUE INC.Montreal.AQUA-SPECTION INC.Québec.AQUEDUC DU VILLAGE DE STANHOPE.St-Mathieu-de-DixvUle .L'ARAIGNEE INC.Montreal.ARCAND AUTO BODY INC.Montreal.ARC-EN-CIEL.VENTE 4 SERVICE LTEE.Montréal. 6564 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.U5 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1963, 1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1967 incl.et/ and 1973.Gatineau.1964 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles .1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Hull.1963 à/to 1973 incl.St-Lambert.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Joliette.1967 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1963, 1966 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1972 et/and 1973 Montréal.1967.1968.1971 à/to 1973 incl.Gatineau.1970, 1972 et/and 1973 Gharlesbourg.1966 à/to 1973 incl.Boucherville.1969 à/to 1973 incl.Causapscal.1969 à/to 1973 incl.Duberger.1964, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Kénogami.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962.1963, 1965, 1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 ardex metal inc.arnel construction co.ltd.artpat promotions inc.ashley's (dorchester) ltd.l'association des administrateurs scolaires.association de chasse et de peche de lytton et montcerf association des citoyens de pointe-aux-trembles association des classificateurs d'oeufs du quebec l'association des commissions scolaires du diocese hull inc.association des distributeurs koscot de montreal inc.l'association des distributeurs de tabac en gros de la province de quebec l'association des employes independants de ciment independant inc.l'association des epiciers-licencies du district de quebec inc.l'association feminine progressiste-conservatrice du district de montreal association française des distributeurs holiday-magic du grand montreal inc.l'association des huissiers du district judiciaire de quebec association des marchands du centre-ville de thetford mines inc.association des marchands et professionnels de ville emard inc.association moto-neiges les lievres inc.association des parents d'enfants deficients visuels de la province de quebec association professionnelle des pet shops inc.l'association des proprietaires de machinerie lourde de l'est du quebec association des proprietaires de la ville de duberger inc.l'association quebecoise des techniques de L'Eau association radio-eclair inc.atlas mechanical industries ltd.atlas-webster industries ltd.atwater paint company limited. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6565 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed AU APOLLO XI LTEE.AU COCHON D'OR INCORPOREE.AU GOURMET (SHERBROOKE) INC.AU PETIT BARIL (1967) LTEE.B.R.T.INTERNATIONAL INC.B ,v S PAPER PRODUCTS INC.B.Y.TERRAIN DEVELOPMENT LTD.BEAUPRE & FILS LTEE.BELGO KNITTING COMPANY INC.LA BELLE BOUTIQUE INC.BEST VALUE MERCHANDISING CO.LTD.MARCEL BOISVERT LTEE.BON APPETIT INC.BOURQUE AUTOMOBILE INC.BOURQUE & BOURQUE INC.LA BOUTIQUE MONSIEUR LTEE.BOUTIQUE LA PERRUQUE QUEBECOISE (RIMOUSKI) BOUTIQUE YVETTE INC.BRIGADOON SCOTCH DISTRIBUTORS (QUEBEC) LTD- B RITE-LITE INDUSTRIES INC.BROMET CONSTRUCTION COMPANY LTD.BROMONT CONSTRUCTION LTD.BROOKS-BURNETT INC.BROSSARD YOUTH RECREATION ASSOCIATION.BROSSEAU AUTOMOBILES & FILS INC.PIERRE BROUSSEAU CINE-CASTING INC.BRULEX INC.BRUMMER MANUFACTURING CORPORATION.BRYSON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.BUDGET FASHIONS INCORPORATED.BUFFET MONACO INC.BUFFET NANTEL INC.BURGERVTLE FISH AND GAME CLUB INCORPORATED.BURNT HILL TUNGSTEN & METALLURGICAL LIMITED.Montréal.1970 à/to 1973 inc.Hull.1963, 1964, 1966, 1967 1969 à/to 1973 incl.Bonsecours.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Anjou.1966 à/to 1970 incl.1972 et/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Sorel.____ 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Acton Vale.1967 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1967 et/and 1973 Hull.1962 à/to 1964 incl.1966, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Dorion.1965 à/to 1967 incl., 1970, 1972 et/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968 à/to 1973 inc.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1960 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Brossard.1968 à/to 1973 incl.Granby.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Québec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Bryson.1972 et/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.St-Eustache.1968.1971 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1971 à/to 1973 incl.Bouchette.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl. 6566 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.46 Nom de la compagnie Name of the company BU-RO INC.BURROW CO.LTD.C.& C.DESIGNS LTD.C.L.INVESTMENTS INC.C.S.DRABBLE OIL BURNERS LTD.CAFE CHEZ-PAUL INC.CANADA LIME AND BUILDERS SUPPLIES LTD.CANADIAN MAID MANUFACTURING CO.LTD.CANDIAC INDUSTRIAL LEASEHOLDS INC.CANITAL CONSTRUCTION LTEE.CANUCK'S TRAVEL CLUB INC.CAPARO INC.CAPITOL STEEL PRODUCTS LIMITED.CENTRAL PAINTING LTD.CENTRE COMMERCIAL CULTUREL DE L'EST INC.CENTRE DE L'ESSOR CULTUREL INC.CENTRE FEMININ DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (MONTREAL) INC CENTRE D'INFORMATION AUX VISITEURS (CIVIC) INC.CENTRE DE LOISIRS DE ST-ONESIME INC.CENTRE MEDICAL BROSSARD INC.CENTRE SOCIAL ESPAGNOL DE MONTREAL.LA CHAMBRE DE COMMERCE DES JEUNES DE VILLE DE BROSSARD.CHAUSSURE FAMILIALE INC.CHAUSSURES CHEZ PAT LTEE.CHAUSSURES ORLY INC.CHEZ DENY8E BRUYERE INC.CHOMEDEY DRIVE-IN INC.CHOMEDEY MAIL ORDER HOUSE LTD.CHOMEDEY REMBOURRAGE INC.CHOMEDEY SOCIAL & RECREATION INC.LA CHORALE DES VOIX LAURENTIENNE8 DE MONTREAL INC.CHOUINARD CONSTRUCTION LTEE.CHRISTIAN ET MARCEL DE PARIS INC.CIDORGE LTEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Québec.1970 à/to 1973 incl.Westmount.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1966, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1962 à/to 1973 incl Québec.1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1972 et/and 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.8t-Onésime d'Ixworth.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Brossard.1968 à/to 1973 incl.St-Hubert.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/t0 1973 moI.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Laval.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Chomedey.1968 à/to 1973 incl.Chomedey.1963 à/to 1973 incl.MontréaI.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1969, 1971 à/tr.1973 inol.' GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° io 6567 Nom de la compagnie Name of Ike company LA CIE DE CONSTRUCTION BRUNO RODRIGUE LTEE.LA CIE DE TAPIS DE CAOUTCHOUC EXCEL LIMITEE.CIFAX INC.CINE CRAFT PRINTING LTD.CINEMAT INC.CIPELA INVESTMENT CORP.CIVIC PROMOTION AND SERVICES INC.LES CLANDESTINS-VALLEYFIELD.CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DU RICHELIEU INC.CLAUDE GALA INC.CLAYMORE INVESTMENTS INC.CLEANAIRE LTD.CLEAN-IT-ERIA INC.CLEAR PACK INC.CLEARVIEW DEVELOPMENT CORP.CLERO MINES LTD.CLIMABEC INC.O.CLOT GRAPHITE MINING LTD.(no personal liability).R.CLOUTIER ELECTRIQUE INC.CLOVAN CONSTRUCTION LTEE.CLOVER DEVELOPMENT INC.CLOVER INC.CLOVER LEAF HOUSING INC.CLUB APRES-SKI INC.CLUB ARC-EN-CIEL INC.CLUB AUTO NEIGE DU LAC BROMPTON.LE CLUB DATSUNAMIS DE QUEBEC INC.CLUB DES JOYEUX MONTAGNARDS INC.CLUB MARAYNORD INC.CLUB OPTIMISTE POINTE-AUX-TREMBLES-MONTREAL-EST INC.LE CLUB OPTIMISTE DE RAWDON INC.CLUB RICHELIEU CHOMEDEY.CLUB DE SKI OOK-PIK INC.CLUB SOCIAL L'ARAIGNEE INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Laurent.1960, 1962, 1963, 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1961, 1962, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valley field.1972 et/and 1973 Sorel.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968.1972 et/and 1973 Montreal.1959 à/to 1973 incl.Val d'Or.1970 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1965 à/to 1973 incl.Labelle.1969 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts.1965 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1970 incl., 1972 et/and 1973 Ste-Anne-de-Beaupré____ 1968 à/to 1973 incl.Victoriaville.1969 à/to 1973 incl.St-Denis de Brompton.1969 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Ferme Neuve.1959 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1964 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles- 1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Rawdon.1970 à/to 1973 incl.Chomedey.1965 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl. 6568 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1973.Vol.105.No.45__ Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Duvernay.1966 à/to 1973 incl.Lac Sergent.1965 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1961 à/to 1973 incl.Bolton.1972 et/and 1973 St-Michel-des-Saints- 1960 à/to 1973 incl.Montréal.1961 à/to 1973 incl.Québec.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Westmount.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1963 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Michel.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1983 a/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1968, 1970 à/to 1973 incl.Longueuil.1964.1966 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Arnaud.1966.1968 à/to 1973 incl.Labelle.1962.1964 à/to 1966 incl., 1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Magog.1965 à/to 1973 incl.Outremont.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1961 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Drummondville.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Nom de la compagnie A'amf of the company CLUB SOCIAL DE DUVERNAY INC.CLUB SPORTIF DE L'ERABLIERE.CLUB VAGABOND INC.CLUB DES VAGABONDS INC.CLUB VAL CLEO INC.COAST TO COAST ENTERPRISES LTD.COLBERT CONSTRUCTION INC.COLE ENTERPRISES INC.WILLIAM COLEMAN INTERNATIONAL INC.COLFAX MINING LIMITED (no personal liability).COLFILD (QUEBEC) LIMITED.COLIMAR INC.LA COLOMBIERE INC.COLONIA DEVELOPMENT (ST.FRANÇOIS) LTD.COLONY DEVELOPMENT CORPORATION.COLOR SEPARATION SERVICE INC.COLORLABO SERVICE INC.COLORTEX DYEING CO.COLUMBIA SPECIALTIES INC.COLVAN INVESTMENT CORPORATION.COMEL LTEE.COMFORT HOSIERY CO.LTD.COMINPEX INTERNATIONAL INC.COMITE DE LOISIRS DE CLARKE CITY.LE COMITE DES LOISIRS DE LABELLE.COMMAND HEADWEAR INC.LA COMMISSION D'AMENAGEMENT ET DE PLANIFICATION REGIONALE DES CANTONS DE L'EST INC.(C.A.P.R.INC.) COMP FOTO INC.COMPACT AGENCY (RIVE-SUD) INC.LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION PLAZA LTEE.LA COMPAGNIE J.M.CLEMENT (STE-FOY) LTEE.COMPTEX CONSTRUCTION LTEE.LE COMPTOIR FAMILIAL (DRUMMONDVILLE) INC.COMPUTER PLACEMENT SPECIALISTS LTD. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6569 Nom de la compagnie Xante of the company COMTEL CORP.CONCEPT COMPUTER SERVICES LTD.CONCORDIA TRADERS INC.CONEX CORPORATION.CONFECTION ST-URSULE LTEE.CONFEDERATION QUEBECOISE DES ENTREPRISES DES LOISIRS.CONFEDERATION DES SPORTS DU QUEBEC INC.CONGRESS HOUSING INC.CONSEIL D'ORIENTATION ECONOMIQUE DE MONTCALM.CONSTRUCTION BRUNET 4 MONGEAU INC.CONSTRUCTION BRYGILLE LTEE.CONSTRUCTION ESCALE LTEE.LA CORPORATION DOMICILIAIRE NOTRE DAME DU FOYER INC.CORPORATION DE PLACEMENT ET DE FINANCE PROMA LTEE.CORPORATION TOURISTIQUE LA MANIE.CREDIT DRECO LTEE.CYBELLE COIFFURE INC.D 4 M SALES AGENCY LTD.DARNELL STAMP AND COIN COMPANY LTD.DART MINING LTD.DE SALABERRY PERSONNEL SERVICES LIMITED____ LES DECORS CINEMATOGRAPHIQUES DE LTSLE D'ORLEANS INC.DEMONTIGNY ACCESSOIRES D'AUTOS INC.J.R.DEVEREUX (60) LIMITED.DISERCO LTEE.LES DISQUES APOLLO INC.DISQUES EXPRESS INC.LES DISQUES REVOLUTION INC.LES DISQUES TREMPLINS INC.LES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS INC.DISTRIBUTEURS L.P.S.INC.DISTRIBUTEURS LAFAYETTE INC.DISTRIBUTEURS LASALLE INC.DISTRIBUTEURS DE PATATES LIMITEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Ursule.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Ste-Julienne.1963 à/to 1973 incl.Anjou.1972 et/and 1973.Longueuil.1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Woodbridge.1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Mont Royal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 incl.St-Laurent.1968 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Trois-Riviéres.1967.1969.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1960, à.to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Mont-Royal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Saint-Pierre-,.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965'à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl. 6570 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Nom de la compagnie Xante of the company DISTRIBUTION DE PNEUS R.L.INC.DISTRIBUTION PROVINCIALE INC.DISTRIBUTION PUBLIQUE LAVAL INC.DISTRIBUTION RIVE SUD INC.DISTRIBUTIONS EXPRESS INTER-CANADA LTEE (LES).LES DISTRIBUTEURS J.P.NOLIN LIMITEE.LES DISTRIBUTIONS MINI MAXI INC.DISTRIBUTIONS NORMAC LTEE.LES DISTRIBUTIONS OLYMPIQUES INC.LES DISTRIBUTIONS TONY INC.JULIUS DIZGUN INC.DOLCLARE ENTERPRISES LTD.DOMAINE D'IBERVTLLE LTEE.LE DOMAINE DU LAC ECHO INC.GEORGE J.DONALSON INC.DONNACONA FUR LTD.DORAL MINING EXPLORATIONS LIMITED.DORLEC CORPORATION.DORNHAM MILLS LTD.DOR-SAY LINGERIE LIMITED.DORTA INVESTMENTS LTD.HUNTER DOUGLAS LIMITED.WILLIE DOWNEY INC.DRAGAGE RIMOUSKI INC.DREAMTEX CORPORATION.DRESSO INC.RALPH DRUCKMAN INC.DUBE AUTOMOBILE INC.GUY F.DUBUC LTEE.PIERRE DUFOUR INC.DUGEDITH COMPANY LTD.DULGOR HOLDINGS INC.DUMAR LTD.GUY DUMONT CONSTRUCTION INC.DUNHILL HOLDINGS LTD.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Stoneham.1969.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1968, 1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Anjou.1970 à/to 1973 incl.Granby.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à.'to 1973 incl.Rivi6re-du-Loup.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 et/and 1973 Montréal.1965, 1969 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967.1971 à/to 1973 incl.Montreal .1972 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1971 à/to 1973 incl.Boucherville.1964 à/to 1973 incl.Rimouaki.1968.1971 à/to 1973 inc.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Jean.1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1965 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1967.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1964, 1965.1970 à/to 1973 incl.Cowansville.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° iô 6571 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed DURA INC.DURCO INC.DUREX CONSTRUCTION LTD.DURHAM REALTIES INC.DURNO CONSTRUCTION LTD.DUVAL AUTOMOBILE LTEE.GILLES DUVAL INC.DYNAMIC SIGNS INC.E.& H.CORPORATION.E.P.V.INC.EAGLE DEVELOPMENT LIMITED.EAST VENTURES LIMITED (no personal liability).EASTBROOK INVESTMENT LTD.EASTPORT TRADING CO.LTD.L'ECOLE CINQ MARS INC.EDAL CONSTRUCTION INC.H.EDELSTEIN ENTERPRISES INC.EDIFICE BRASSARD INCORPOREE.EDIFICE LANGLAIS LIMITEE L'EDIFICE TE8SIER LTEE.LES EDITIONS DE LA COMPETITION INC.EDITIONS DE L'ECHO INC.LES EDITIONS ESTEREL LTEE.LES EDITIONS DE LTSLE INC.LES EDITIONS POLYOR INC.LES EDITIONS RUCO LTEE.LES EDITIONS LE SAGUENAY INC.EDITIONS SEGA INC.L'EDITORIAL INC.Montréal.1968 à/to 1973 ncl.Québec.1972, 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.St-Lambert.1964, 1965, 1967, 1971 à/to 1973 incl.Châteauguay.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1966, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Verschelden.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Arvida.1953.1964, 1971à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Hull.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Vaudreuil.1958, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1963 à/to 1973 incl.Ile-des-Soeurs.1970 à/to 1973 incl.Beauport.1963 à/to 1973 incl.EFFICIENT EQUIPMENT INC.Baie-Comeau.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.ELDRIDGE DEVELOPMENT CORP.Montreal.1959, 1961, 1965, 1966, 1969 à/to 1973 incl.ELECTRA COMPANY LIMITED.Montreal.1970 à/to 1973 incl.ELECTRA PARK DEVELOPMENT LTD.Montreal.1967 à/to 1973 incl.ELEGANT TAPIS INC.Montréal.1965 à/to 1973 incl. 6572 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 107.1.Vol.105.No.!,:>_ Nom de la compagnie Name of the company ELTO REALTIES LTD.L'ENTRAIDE MASKOUTAINE INC.ENTREPRISE ERIGO INC.ENTREPRISES R.C.M.INCORPOREE.LES ENTREPRISES ARBELA INC.LES ENTREPRISES BRUSSEAU LTEE.ENTREPRISES CÀNTJHA INC.ENTREPRISES CINE-DIFFUSION INC.LES ENTREPRISES DOMESTIQUES INC.ENTREPRISES DOUBLE J.LTEE.LES ENTREPRISES DUCLOS & DUCLOS INC.ENTREPRISES ERIC VILON INC.ENTREPRISES GOTHAM INC.LES ENTREPRISES LA-RI INC.LES ENTREPRISES M.C.LTEE.LES ENTREPRISES M.D.M.LTEE.ENTREPRISES MON-BRU INC.LES ENTREPRISES ORION INC.ENTREPRISES LUCIEN OUELLET INC.ENTREPRISES PANA-EST INC.ENTREPRISES PANORAMA INC.LES ENTREPRISES PAYSAGISTES LTEE.LES ENTREPRISES POLY-DOR LTEE.EPARGNEX INC.EPOCAST CO.LTD.EPSILON CONSTRUCTION LTEE.EQUIPE PASTORALE DE LTMMACULEE-CONCEPTION____ EQUIPEMENT DE BUANDERIE ET DE NETTOYAGE A SEC INTERNATIONAL LIMITEE.LES EQUIPEMENTS COMETE LTEE.ERMEL INVESTMENT CO.LTD.ERNLE REALTIES INC.ESELEM CONSTRUCTION CO.LTD.ESSIAMBRE INC.ESTONIAM BAKERY INC.Adresse Rapports non produits Addreti Returns not filed Montreal.1972 et/and 1973 incl.St-Hyacinthe.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1969.1970, 1972 et/and 1973 Sainte-Foy.1972 et/and 1973 Saint-Bruno-de-Montar- 1968 à/to 1973 incl.ville.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Deux-Montagnes.1972 et/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Brosaard .1967 à/to 1973 incl.Duvernay.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Deux-Montagnes.1967 et/and 1973 St-André d'Argenteuil.1969 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Anjou.1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Laval.____ 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 St-Nicolas.1965.1967, 1969 à/to 1973 incl.Dorion.1966 à/to 1973 incl.Hauterive.1969 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse-de-Blainville 1962.1964 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Boucherville.1961, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1966.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 197S, 105' année, n° 45 6573 Nom de la compagnie Xamc of the company ESTRACAL INC.FAMOUS COFFEE SHOP INC.FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DES ECOLES PROTESTANTES FRANÇAISES DU QUEBEC.FEDERATION SUB-AQUATIQUE DU QUEBEC INC.LES FERMES DUCHESS INCORPOREES.FLEURCO INDUSTRIES (1963) LTD.FORWARD HOLDINGS LTD.G.FOURNIER LTEE.YVON FOURNIER INC.FOYER DE MAGOG INC.FRUITS E.U.INC.G 4 N SCHOOL BUS SERVICE INC.GALERIE DES VALEURS (DRUMMOND) INC.GAYE DUNHILL ORIGINALS INC.GENERAL COMPUTING CORPORATION OF CANADA, LIMITED.GESTION PABRINIC LTEE.GIBBS, NATHANIEL 4 CO.LTD.GLAMOUR FURS INC.GOLDEN GRADE CLOTHES INC.GOLMOR MFG.INC.GORAN REALTY LTD.GORDON AUTO PARTS LTD.RAYMOND GOULET LIMITEE.LE GOURMET INTERNATIONAL (MONTREAL) INC.LA GOUTTIERE INC.GRANBY MUSHROOM LTD.GRANBY PULP 4 PAPER COMPANY.GRAY ELECTRIC COMPANY.THE GREEK CANADIAN NATIONAL BROTHERHOOD- LE GROUPEMENT DES HOTELIERS ET DES RESTAURATEURS DE L'EST DE LA PROVINCE INC.GROUPEMENT DES LOCATAIRES DU QUEBEC METROPOLITAIN (G.L.Q.M.) INC.JEAN-PIERRE GYSIN INC.JEAN-CLAUDE HAMEL INC.HAND 4 DONOHUE CO.LTD.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Terrebonne.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1966 à'to 1969 incl., 1972 et/and 1973 Sherhrooke.1965.1966.1968 à/to 1973 incl.Magog.1971 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1969, 1971 à/to 1973 incl.Outremont.1968 à/to 1973 incl.Drummondville.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Nicolet.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970.1972 et/and 1973 Montreal.1967, 1968 et/and 1973 Montreal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Philomène.1964, 1966 à/to 1973 incl.Sorel.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Granby.1960 à/to 1973 incl.Granby.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.St-Romuald d'Etchemin.1969 à/to 1973 incl.Québec.1972, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.LaSarre.1968 à/to 1973 incl.Westmount.1964,1971, à/to 1973 incl. 6574 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Nom de la compagnie\tAdresse\tRapports non produits Name of the company\tAddress\tReturns not filed L'HARMONIE DE DRUMMONDVILLE INC.\tDmmmondville.\t.1967, 1972, 1973 \t\t1972, 1973 HI & LO STORES LIMITED.\tDorval.\t1972, 1973 HOTEL OBALSKI LIMITED.\tChibougamau.\t.1969, 1971 à/to 1973 incl.HOUDE, LAWRENCE, DUPONT AND ASSOCIATES INC.,\t\t1967 à/to 1973 incl.\tHull.\t1970 à/to 1973 incl.\t\t.1969 à/to 1973 incl.I.E.P.CORPORATION.\tMontreal.\t1969 à/to 1973 incl.ILIAN ASSOCIATION \u2022 ERMIS \u2022.\tOutremont.\t1965 à/to 1973 incl.LES IMMEUBLES CANABEC INC.\tQuébec.\t1972.1973 LES IMMEUBLES DOLINI INC.\t\t1965 à/to 1973 incl.IMMEUBLES EDNA INC.\t\t1966 à/to 1973 incl IMMEUBLES STE-THERESE OUEST INC.\t\t1969 à/to 1973 incl.IMPRIMERIE BROSSARD LTEE.\t\t.1969 à/to 1973 incl.IMPRIMERIE DOLBERT INC.\t\t IMPRIMERIE EDWARDS INC.\tLaSalle.\t1967 à/to 1973 incl.INDUSTRIAL COMMUNICATIONS PRODUCTS CO.INC.\t\t.1970 à/to 1973 incl.LES INDUSTRIES COMETE LTEE.\t\t.1971 à/to 1973 incl.\t\t INTERNATIONAL BUDDIES ASSOCIATION INC.\t\t LES INVESTISSEMENTS J.C.R.LTEE.\t\t LES INVESTISSEMENTS GRACE PARK INC.\t\t INVESTISSEMENTS PERRON INC.\t\t.1968 à/to 1973 incl.\t\t1 QfiQ *i )n 1Q71 incl JAN'S PUBLISHING COMPANY LIMITED.\t\t.mou a/to ifio inci.1972, 1973 JARDINS D'OKA INC.\tOka.\t1970 à/tn 1Q71 incl \tPont-Viau.\t.\u2022 .lolu a/lO IWiO lilt 1, .1967 à/to 1973 incl.JEWISH DEFENCE LEAGUE OF QUEBEC.\t\t.1971 à/to 1973 incl.\t\t1 Qfi7 1 Q7ft à /frt 1 Q71 inol \t\t.i.fi, i9iu .l.ii l.i,.) incit 1970 à/to 1973 incl.KINGSMEN CLUB OF NOTRE-DAME DE GRACE.\t\t.1959, 1966 à/to 1973 incl.THE KIPARISSIOTON BROTHERHOOD OF CANADA.\t\t.1969 à/to 1973 incl.KLEEN-BRITE MAINTENANCE LTD.\t\t.1970 à/to 1973 incl.KLNR DISTRIBUTORS LTD.\t\t1Q7Î à ttf\\ lQ7^i inpl E.KOTLER REALTY CORP.\tMontreal\t¦ .ii a/to i .'i ¦! incl.1Q17 1Q7A ,'.\u2022 1 (VTQ ?_1 \t\txvoi, iyrt de marchandises pour le compte de Les transports de la Baie d'Hudson inc./ Hudson Baie Transport Inc., détentrice du permis 22499-V, selon les clauses a.b et c dudit permis.Construction de la traverse :\\ niveau.La partie requérante a déposé à la Commission des transports du Québec une résolution portant le No 73-284 datée du 0 août 1073, demandant la Commission des transports du Québec de l'autoriser à construire une traverse a niveau comme suit: 1) Construction d'une traverse A niveau sur le lot 630-2 du cadastre officiel de la Paroisse de St-Jérôine-de-Matane, comprise dans les limites de Matane: 2) La partie requérante accepte les frais de construction et d'entretien de cette traverse a niveau tel que décrite, au document P-4 (description technique).P-5 Plan No 1-1438.Application for permit.The applicant wishes to have the following permit from the Québec Transport Commission: Restricted trucking - long distance - restricted route - From St.Malachie to St.Romuald and Vallée Jonction, for the transportation of livestock.Modification of permit.The applicant requests to add the following service to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Sept-Iles to Baie Comeau and return, for the transportation of explosives on behalf of Dupont of Canada Ltd.Application for permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - contract -Transportation of goods on behalf of Les transports de la Baie d'Hudson inc./ Hudson Bay Transport Inc.holder of permit 22499-V according to clauses a.b and c of said |>ermit.Construction of a railroad crossing.The applicant has filed with the Québec Transport Commission a resolution bearing number 73-284, dated August 0, 1973, requesting the Québec Transport Commission to authorize it to construct a railroad crossing as follows: (1) Construction of a railroad crossing on lot 630-2 of the official cadastre for the Parish of St.Jérôme-de-Matane.comprised within the limits of Matane; (2) The applicant accepts the costs for the construction and maintenance of this railroad crossing as described in document P-4 (technical description).P-5 Plan number 1-1438. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6601 Rôle Q-327 225-A-D-l TF CAMILLE MAILLOUX INC., 331, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup, Cté Rivière-du-Loup, P.Q.Rôle Q-328 10853-V-D-l TRANSPORT IDEAL INC., 35, rue St-Paul, B.P.218, Station .B-, Québec 2, Cté de Québec.Demande d'augmentation do taux pour transport par autobus de voyage à charte-partie comme suit: Taux actuels: Taux proposés: S 0.50 du mille.810.00 l'heure S 0.65 du mille 810.00 l'heure Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service additionnel suivant : Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De Québec et de St-Romuald-d'Etchemin h tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Montmorency et Charlevoix, pour le transport de grain et moulée finie en vrac et en sacs, avec équipement spécialement agencé pour ce genre de marchandise, pour le compte de Ralston Purina du Canada Ltée, Moulées Supersweet Ltée et La Ferme de la Poulette Grise Inc.et/ou La Poulette Blanche Inc.et/ou Couvoir Dufo Inc.Request for an increase of rates for charter bus trips as follows: Current rates: S 0.50 per mile covered 810.00 per hour.Proposed rates S 0.65 per mile covered $10.00 per hour.Modification of permit.The applicant requests to add to its permit the following additional service: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Québec and St.Romuald-d'Etche-min to all points located in the provincial electoral District of Montmorency and Charlevoix, for the transportation of grain and complete feed in bulk or in bags, with special equipment designed for this kind of goods, on behalf of Ralston Purina du Canada Ltée, Moulées Supersweet Ltée and La Ferme de la Poulette Grise Inc.and/or La Poulette Blanche Inc.and/or Couvoir Dufo Inc.Rôle Q-329 1276-dy d.1 F.R.DALLAI RE INC.4196, Rue Laval, Lac Mégantic, Comté de Frontenac Rôle Q-330 23482-V-D-l JEAN-LOUIS LACOURSIERE, 316-A, 6e Avenue, Grand-Mère, Cté Champlain.Rôle Q-331 715-DY & 264-DYV LOCATION UNIVERSELLE INC., 777, 1ère Avenue, Québec.Rôle Q-332 2779-A-D 1 ARMAND AUDET, St-Camille, Cté Bellechasse, P.Q.et GAETAN CARRIER, St-Camille, Cté Bellechasse, P.Q.Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service: Location à long terme (une année de plus) de véhicules de promenade.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local - contrat - Grand'Mcre et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de mets préparés, pour le compte de Restaurant Bravo Pizzeria.Droits additionnels: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services additionnels de location de véhicules comme suit: Service 3: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade (Automobiles, Familiales ou Station Wagons et Maisons Mobiles) à 777, 1ère Avenue, Québec.Service 4 : Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de livraison (Camions n'excédant pas une tonne), à 777, 1ère Avenue, Québec.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder à Gaétan Carrier, St-Camille, Cté Bellechasse, P.Q.le permis No 2779-A-Dl.La propriété du système de transport suivant: Service 1 : Transport d'écoliers le midi de leur résidence située dans les limites de St-Camille (environ cinq milles à l'ouest sur la route 24) au Couvent du Village de St-Camille et retour; New application.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following vehicle - leasing services : Service: Leasing of pleasure vehicles on a long-term basis (one year or over).Application for permit.The applicant requests the following permit : Restricted trucking - local service - contract - Grand'Mcre and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of the said City, for the delivery of prepared foods, on behalf of Restaurant Bravo Pizzeria.Additional rights.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following additional vehicle-leasing services: Service 3: Leasing of pleasure vehicles (automobile, station-wagons and mobile homes) on a short-term basis (less than a year) at 777 - 1st Avenue, Québec.Service 4 : Leasing of delivery vehicles (trucks weighing less than one ton) on a short-term basis (less than a year) at 777 - 1st Avenue, Québec.Transfer of the ownership of the transportation services (sale).The applicant requests authorization to transfer to Gaétan Carrier, St.Camille, County of Bellechasse, P.Q.permit No.2779-A-D 1.The ownership of the following transportation service : Service 1: Transportation of pupils at noontime from their residence located within the limits of St.Camille (about five miles west of Highway 24) to the Convent of the Village of St.Camille, and return; 6602 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.1>5 Rôle Q-333 5427-V-D-2 RIMOUSKITRANSPORT LIMITÉE, 377 - 2e Rue est.Rimouski, Cté de Rimouski Rôle Q-334 23479-V-D-l LEONARD BANVILLE, 206, De la Sapinière, Sacré-Coeur, Cté de Rimouski Rôle Q-335 443-V-D-l HARVEY TRANSPORT LIMITÉE, 2900.ave.du Pont, C.P.580, Aima, Cté du Lac St-Jean.Rôle Q-336 6898-V-D-l TRANSPORT C.GAGNON LTEE, 13, rue Napoléon, St-Bruno, Cté du Lac St-Jean, G0W 2L0 Rôle Q-337 1123-DY D-l PRIMA AUTOMOBILES INC., 595, rue Hébert, St- Pascal.Cté de Kamouraska, P.Q.Conditions et restrictions: Ce service est restreint au transport d'écoliers le midi, et ce, aux jours de scolarité.Service 2: Voyages spéciaux ou à charte-partie de Ste-Sabine et destinés à St-Luc, St-Camille.Ste-Rose, Ste-Justine, St-Prosper, St-Za-charie, Ste-Germaine, Ville et Station, St-Odilon et St-Damien pour le transport des joueurs de hockey et de leurs supporteurs; Service 3: Voyages spéciaux ou ù charte-partie de St-Camille (Bellechasse) à tout endroit situé dans un rayon de cinquante milles (50).Conditions et restrictions: 1) Ce permis sera valide tant et aussi longtemps que le requérant détiendra un contrat de la Commission scolaire pour le transport des mêmes écoliers, matin et soir, sur le même parcours que celui du midi.2) Ce permis n'accorde aucun droit de l'Ordonnance générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Modification de permis (voiturier-roulier).La partie requérante demande le permis suivant: Autorisation d'utiliser, pour le transport de marchandises autorisé par les clauses c, d et / de son permis No 5427-V, le service de remorquage de: Léonard Banville, 23479-V, voiturier-re-morqueur 206, De la Sapinière, Sacré-Coeur, Comté de Rimouski.Demande de permis de voi tu rie r-remorqueur.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses c, d et f du permis No 5427-V, pour le compte de : Rimouski Transport Limitée, 5427-V, voiturier-roulier, 377, 2ième Rue est, Rimouski, Comté de Rimouski.Modification de permis (voiturier-roulier).La partie requérante demande le permis suivant: Autorisation d'utiliser, pour le transport de marchandise autorisé par les clauses a k w inclusivement de son permis No 443-V, le service de remorquage de: Transport C.Gagnon Ltée, 6898-V, voi-turier-remorqueur.13.rue Napoléon, St-Bruno.Comté du Lac St-Jean, G0W 2L0.Demande de permis voiturier-remorqueur.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses a à w inclusivement du permis No 443-V, pour le compte de: Harvey Transport Limitée, 443-V, voiturier-roulier, 2900, ave.du Pont, CP.5S0, Aima, Comté du Lac St-Jean.Demande de changement d'adresse.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, de l'autoriser a changer l'adresse de la place d'affaire pour être à l'avenir située à 230, 4t*me Rue, C.P.310, Saint-Pascal.Comté de Kamou-raska.Conditions and Restrictions: This service is restricted to the transportation of students at noontime, the foregoing during the schooldays-Service 2: Special or charter trips from Ste.Sabine to St.Luc, St.Camille, Ste.Rose, Ste.Justine, St.Prosper, St.Zacharie, Ste.Germaine town and station, St.Odilon and St.Damien for the transportation of hockey players and their fans.Service 3: Special or charter trips from St.Camille (Bellechasse) to any points located within a radius of fifty miles (50).Conditions and Restrictions: (1) This permit shall be valid as long as the applicant shall hold a contract from the School Commission for the transportation of the same students, morning and night, on the same route followed at noontime.(2) This permit does not allow any of the privileges granted by General Order No.17 respecting special or charter trips.Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit: Authorization to utilize, for the transportation of goods authorized by clauses c, d, and /of its carrier's permit No.5427-V, the haulaway transportation service of: Léonard Banville, 23479-V, haulaway operator, 206, De la Sapinière, Sacré-Coeur, County of Rimouski.Application for a permit of haulaway operator.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul with his duly-registered tractors, empty or loaded trailers, according to clauses c, d and / of permit No.5427-V.on behalf of: Rimouski Transport Limitée, 5427-V, carrier, 377 - 2nd Street East, Rimouski, County of Rimouski.Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit: Authorization to utilize, for the transportation of goods authorized by clauses oto m inclusive of its carrier's permit No.443-V, the haulaway transportation service of: Transport C.Gagnon Ltée.6898-V, haulaway operator.13, Napoléon Street, St.Bruno.County of Lac St-Jean.GOW 2L0.Application for a permit of haulaway operator.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul with its duly-registered tractors, empty or loaded trailers, according to clauses a to u> inclusive of permit No.443-V, on behalf of: Harvey Transport Limitée, 443-V, carrier, 2900 du Pont Avenue, P.O.Box 580, Alma.County of Lac St-Jean.Application for change of address.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to change the address of its place of business that will be henceforth located at 230- 4th Street - C, P.O.Box 310, St.Pascal, County of Karnou-raska. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n' 45 6603 Rôle Q-338 311-DY & 66-DYV D-l ROMPRE & FRERE DRIVE YOURSELF LTEE.1303, Avenue Maguire.Sillery, Québec, P.Q, Rôle Q-339 1277-DY & 1058-DYV D-l CHATEL AUTOMOBILES LTEE 640 ouest, rue Arago, Québec.P.Q.Rôle Q-340 2003-V-D-l J.-EUGENE BOUCHFR, C.P.S02, Grand'Mère.Cté St-Maurice.et FERRIER MARCOUILLER, 200, OSème Rue, St-Théophile, Cté Champlain.Requérantes / Applicants.Rôle Q-341 3023-A-Dl OVILA THIBOUTOT, C.P.6 St-Pascal, Cté Kamouraska, P.Q.et OVILA THIBOUTOT, INC., C.P.6, St-Pascal, Cté Kamouraska, P.Q.Demande de changement d'adresse d'un bureau de location.La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit: Service : Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade à: ¦\u2014 1303, avenue Maguire, Sillery \u2014 8, rue McWilliam Québec \u2014 Aéroport de l'Ancienne Lorette Location à long terme (un an et plus) de véhicules de promenade à: \u2014 1303, avenue Maguire, Sillery \u2014 8, rue McWilliam.Québec Service : Location à court terme et à long terme de véhicules de commerce à: \u2014 1303.avenue Maguire.Sillery \u2014 S, rue McWilliam.Québec demande à la Commission des transports du Québec de changer l'adresse du bureau de location de 8, rue McWilliam pour être à l'avenir situé à 190, rue St-Jean Québec.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit.Service 1: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de promenade de marque - Mercedes Benz '.Service 2: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce de marque « Mercedes Benz ¦.Cession de la propriété du système de transport.J.Eugène Boucher demande l'autorisation de céder à: Ferrier Marcouiller, 200, 98e rue, St-théophile, Cté.Champlain, la propriété du système de transport opéré en vertu de son permis qui se lit comme suit: No 2003-V.a) Transport général - service local - a) Grand'Mère et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité; 6) Transport général - longue distance -rayon - b) De Grand'Mère à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles de ladite municipalité, et retour.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder à Ovila Thiboutot Inc., C.P.6, St-Pascal, Cté Kamouraska, le permis No 3023-A-D1.La propriété du système de transport suivant: Classe permis: Autobus.Service : Voyages à charte partie de St-Pascal à tout endroit situé dans un rayon de quarante (40) milles de St-Pascal, pour répondre aux besoins d'organisations sportives et autres.Conditions et restrictions: 1) Le voyage à charte partie devra être fait pour un voyage retour entre les points, h une date déterminée à l'avance et à un taux pour le voyage effectué, soit a l'heure Application for change of address of a leasing office.The applicant which is authorized to provide the following vehicle-leasing services: Service : Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than a year) at: \u2014 1303 Maguire Avenue, Sillery \u2014 8 McWilliam Street, Québec \u2014 Airport of l'Ancienne Lorette Leasing of pleasure vehicles on a long-term basis (one year or over) at: \u2014 1303 Maguire Avenue, Sillery \u2014 8 McWilliam Street.Québec Service : Leasing of commercial vehicles on a short-term and on a long-term basis at: \u2014 1303 Maguire Avenue.Sillery \u2014 8 McWilliam Street, Québec requests the Québec Transport Commission to change the address of its leasing office from 8 McWilliam Street to 190 St.Jean Street, Québec.New request.The applicant requests that the Québec Transport Commission authorizes it to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1 : Long term leasing (one year and over) of \"Mercedes Benz\" pleasure vehicles.Service 2: Long term leasing (one year and over) of \"Mercedes Benz\" commercial vehicles.Transfer of the ownership of the transportation system.J.Eugène Boucher requests authorization to transfer to: Ferrier Marcouiller, 200-98th Street, St.Théophile, County of Champlain, the ownership of the transportation service operated under his permit which reads as follows: No.2003-V.(0) General trucking - local service - (a) Grand'Mère and all points located within a distance not exceeding 5 miles from the limits of said municipality; (6) General trucking - long distance -radius - (6) From Grand'Mcre to all points located within a radius of 30 miles from said municipality, and return.Transfer of the ownership of the transportation service (sale).The applicant requests authorization to transfer to Ovila Thiboutot Inc., P.O.Box 6.St.Pascal.County of Kamouraska, permit No.3023-A-D1.The ownership of the following transportation service: Permit class: Bus.Service: Charter trips from St.Pascal to any point located within a radius of forty (40) miles from St.Pascal, to meet the needs of sports agencies and other bodies.Conditions and restrictions: (1) The charter trip must be provided for a return trip between points, on a predetermined date and at a rate for the trip either per hour or per mile or else based on the two 6604 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1973, Vol.105, No.45 Rôle Q-342 3544-A-D1 MONSIEUR PAUL BOURQUE, Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, P.Q.Requérante / Applicant.Rôle Q-343 1269-DY D-I MAURICE AUTORAMA INC., Hauterive, Comté de Saguenay.Requérante/ Applicant.Rôle Q-344 3417-A-D2 MONSIEUR ROLAND LORD, Ste-Louise, Cté L'Islet.P.Q.Requérante / Applicant.Rôle Q-345 3060-A-D1 et 3390-A-D3 AUTOBUS REGIONAL ENR., C.P.81, Chute-aux-Outardes, Route 138 et AUTOBUS COTE NORD INC., C.P.81.Chute-aux-Outardes, Route 138.ou au mille ou encore qu'il soit basé sur les deux points.2) Ces voyages ne devront pas constituer un service répété.3) Les passagers devront compléter les voyages sans arrêt en cours de route, sauf pour se rafraîchir ou se reposer, et à destination pour les fins du voyage.4) Le prix chargé pour ces voyages devra être conforme au tarif déposé par le détenteur et accepté par la Régie.Nouvelle demande de permis.Classe permis: Autobus.Service : Transport des passagers des Hôtels ou Motels à l'aéroport et retour ainsi que visite sur les Iles-de-la-Madeleine avec un mini-bus 14 passagers ainsi que transport et retour du Ferry.Un seul aéroport sur les Iles-de-la-Madeleine.Départ de Cap-aux-Meules ù Havre aux Maisons et retour.Tours sur les Iles en saison touristique.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service : Location ït long terme (une année et plus) de véhicules de promenade.Droit additionnel Classe permis: Autobus.Service: Transport d'étudiants et de chefs de groupe CEGEP La Pocatière à Cap-Rouge, Québec, Ste-Foy, Lévis.Compétition sportives durant l'année scolaire 1973-74.Restrictions: Restreint à ce transport h date fixe indiquée dans la cédule.Cession de la propriété du système de transport (vente*.La partie requérante demande l'autorisation de céder :\\ Autobus Côte Nord Inc., C.P.M, Chute-aux-Outardes.le permis No 3060-A-D-l.La propriété du système de transport suivant : Service: Transport des membres du corps de majorettes Bais-Comeau-Hauterive Inc.soit Les Ambassadrices Manicouagan de Chute-aux-Outardes-Hauterive à Baie-Comeau pour les pratiques durant la semaine.Parcours h suivre: De Chûte-aux-Outardes à Hauterive par la route 138 Hauterive: boul.Laflèche.boul.Bélanger, boul.Joliette.rue de la Falaise, Puyjalon, Joliette, Margueritte.Baie-Comeau: rues Babel, Père, Arnaud.Radisson, Laval, Champlain, Roberval, Mai-sonneuve, Legardeur.Terminus: Baie-Comeau, Ecole Boisvert, rue Legardeur.Conditions et restrictions: 1) Pas de service local sur tout le parcours.points.(2) These trips must not become a repe-tive service.(3) Passengers must complete these trips without stopping on the way, except at rest stop and at their destination point for the purposes of the trip.(4) The price charged for these trips must be in conformity with the tariff filed by the permit holder and approved by the Commission.Request for a new permit.Permit class: Bus.Service: Transportation of passengers from their hotels or motels to the airport and return, including a visit to the Iles-de-la-Madeleine in a 14 passengers mini-bus and the return trip to the ferry boat.One single airport on the Iles-de-la-Madeleine.Departure from Cap-aux-Meules to Havre.aux-Maisons and return.Tours of the Islands during the tourist season.New request.The applicant requests that the Québec Transport Commission authorizes it to provide the following vehicle-leasing services: Service : Long term leasing (one year and over) of pleasure vehicles.Additional Right: Permit class: Bus.Service: Transportation of students and CEGEP group leaders, La Pocatière to Cap-Rouge, Québec.Ste.Foy, Levis.Sporting events during the 1973-74 school year.Restrictions: This service shall be restricted to a fixed date indicated in the schedule.Transfer of the ownership of the transportation service (sale).The applicant requests authorization to transfer to Autobus Côte Nord Inc., P.O.Box 81, Chute-aux-Outardes, permit No.3060-A-D-1, The ownership of the following transportation service: Service: Transportation of the members of the majorette corps Baie-Comeau - Hauterive, namely Les Ambassadrices Manicouagan from Chute-aux-Outardes-Hauterive to Baie Comeau for practicing during the week.Route to follow: From Chute-aux-Outardes to Hauterive along highway 138 Hauterive: Laflèche Blvd., Bélanger Blvd., Joliette Blvd., De La Falaise Street, Puyjalon Street, Joliette Street, Margueritte Street.Baie-Comeau: Babel, Père.Arnaud, Radisson, Laval, Champlain, Roberval, Maison-neuve, Legardeur Streets.Terminal: Baie Comeau: Boisvert School, Legardeur Street.Conditions and Restrictions: (1) No local service shall be provided on the way. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.n° 45 6605 Rôle Q 346 3214-A-D2 MONSIEUR FREDDY ALLARD, V.P.36, St-Omer, Cté Bonaventure, P.Q.Requérante / Applicant.Rôle Q-347 3214-A-D1 MONSIEUR FREDDY ALLARD, C.P.36.St-Omer, Cté Bonaventure, P.Q.Rôle Q-34H 2779-A-D3 LEON CLOUTIER.Route Kennedv.Ville St-Joseph, Cté Beauce, P.Q.Rôle Q-349 21157-V D-l TF SEPT-ILES LABRADOR CARTAGE INC., 294, rue Noël.C.P.310, Sept-IIe».Cté Saguenay.P.Q.Role Q-350 10853-V D-l TF TRANSPORT IDEAL INC.IDEAL CARTAGE INC., 35.St-Paul, B.P.218, Station \u2022 B \u2022.Québec 2.P.Q.Rôle Q-351 336-A D-l TF CORPORATION DE TRANSPORT ROUYN, NORANDA 175, rue Reilly.Rouyn, Cté Téiniscamingue.P.Q.2) Ce permis n'accorde aucun droit aux privilèges de L'Ordonnance générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Droit additionnel: Durant les vacances scolaires, le requérant a droit d'effectuer des voyages spéciaux ou à charte-partie originant de Baie-Comeau et destinés dans la région de Montréal.Québec.La Gaspésie et la région de Chicoutimi pour le compte des Ambassadrices Manicouagan.Droit additionnel: Requête pour obtenir le droit additionnel suivant : (\"lasse permis: Autobus.Service: Transport de joueurs de hockey de l'arcna de New-Richmond aux différents endroits oîi ils sont appelés à jouer soit : Chandler, Murdoehville.Gaspé.Frontière du Nouveau-Brunswick.Modification de permis: Classe ]>ermis: Autobus.Service: La partie requérante qui détient un permis en vertu duquel elle est autorisée a effectuer des voyages spéciaux où à charte-partie des organisations paroissiales de St-Omer à tout endroit dans un rayon de 150 milles demande une modification audit permis de manière à étendre ce rayon à tout endroit dans le Québec.Droit additionnel: Requête pour obtenir le droit additionnel suivant.Classe permis: Autobus.Service: Voyages spéciaux ou a charte-partie de Tring-Jonction, St-Frédéric et Vallée-Jonction, Beauce, à tout point de la province de Québec.Demande d'augmentation de taux de 10% au tarif No 2.La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport de gruin et moulée en vrac, chargé mécaniquement et déchargé à l'aide de souffleur ou en basculant pour le compte des expéditeurs suivants: Ralston Purina du Canada Ltée.Moulées Supersweet Ltée.Master Feeds (Division Les Moulins Maple Leaf Ltée).Demande d'augmentation de tarifs pour le transport de passagers à l'intérieur de la ville de Rouyn-Noranda: Taux actuels: Taux proposés: Adultes (10 nue cl plus): 82.00 pour 10 billets $3.00 pour 1(1 billets 0.25 en argent romp- 0.35 en argent tant comptant (2) This permit does not provided for any of the privileges granted by General Order No.17 with respect to special or charter tri|is.Additional Right: During school holidays, the applicant is entitled to provide special or charter trips from Baie-Comeau to the following regions: Montreal, Québec.Gaspé Peninsula and the Chicoutimi region, on behalf of les Ambassadrices Manicouagan.Additional right : Request for the following additional right: Permit class: Bus.Service : Transportation of hockey players from New Richmond arena to the various points where they are supposed to play: Chandler.Murdoehville.Gaspé, the New Brunswick border.Modification of permit: Permit class: Bus.Service: The applicant who holds a permit by virtue of which he is authorized to take the members of St.Omer parish organizations on special or charter trips to any point within a 150-mile radius, requests that said permit be extended to include all points in Québec.Additional right : Request for the following additional service: Permit class: Bus.Service: Special or charter trips from Tring-Jonction, St.Frédéric and Vallée-Jonction, Beau-ce.to any point in the province of Québec.Request for increasing tariff No.2 by 10%.The applicant requests that the Québec Transport Commission authorize it to increase its tariffs for the transportation of grain and feed in bulk, loaded mechanically and unloaded with blowers or a dumping device, on behalf of the following shippers: Ralston Purina du Canada Ltée, Moulées Supersweet Ltée.Master Feeds (Division Les Moulins Maple Leaf Ltée).Request for a tariff increase for the transportation of passengers in the city of Rouyn-Noranda: Current Rates: Adults (111 and over) $2.00 for 10 tickets 0.25 in cash Proposed Rates: 83.00 for 10 tickets 0.35 in cash 6606 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Rôle Q-352 1572-A D-2 TF VIATEUR OUELLET, O.P.7, Trinité des Monts, Cté Rimouski, P.Q.Rôle Q-353 20534-V D-2 TF ENTREPOT INTER-C1TE INC.| INTER-CITE WAREHOUSES INC., 1440, Semple, Québec S.P.Q Rôle Q 354 15957-Y D-l TF GERARD NOLIN LIMITEE, 150.de l'Eglise.Parc Industriel, C.P.100, St-Jean Chrysostome.Cté Levis.P.Q.Rôle M-541 2957-A RIVERAINS TRANSPORT INC., 555, Boul.Guimond, Longueuil, P.Q.Rôle M-542 2957-A D-l RIVERAINS TRANSPORT INC., 555.Boulevard Guimond, Longueuil.P.Que.Enfante (de 5 à 12 ans): SI.00 pour 10 billets S1.50 pour 10 billets 0.15 en argent comp- 0.20 en argent tant comptant Etudiants (moins de 16 ans): «1.00 pour 10 billets 81.50 pour 10 billets 0.15 en argent comp- 0.20 en argent tant comptant Demande d'augmentation de tarifs d'une moyenne de 11% sur les anciens taux simples.Demande d'augmentation de taux pour consolidation de marchandises i\\ Québec pour destination au service « C » qui se lit comme suit: « De Québec à la partie nord du Nouveau Brunswick et aux comtés électoraux provinciaux de Rimouski.Matane, Matapédia, Bonaventure, Gaspé-Sud et Gaspé-Nord.« Children (5 to 12) 81.00 for 10 tickets 0.15 in cash Students (under 16) S1.00 for 10 tickets 0.15 in cash 81.50 for 10 tickets 0.20 in cash $1.50 for 10 tickets 0.20 in cash Request for an average 11% tariff increase over the former single trip rates.Request for a tariff increase for consolidating, in Québec, goods to be shipped to the following points under service \"C\" which reads as follows : \"From Québec to the northern part of New Brunswick and to the provincial electoral counties of Rimouski.Matane, Mata-pédia, Bonaventure, Gaspé-South and Gaspé-North.\" \t100\t85\t.70\t55\t\t100 85\t70\t55 Zone A\t$2.88\t82.73\t$1 .S4\t$1.79\tZone A\t82.88 $2.73\t81.84\t$1.79 Zone B\t3.31\t3.25\t2.16\t2.10\tZone B\t3.31 3.25\t2.16\t2.10 Zone C\t3.54\t3.48\t2.34\t2.28\tZone C\t3.54 3.48\t2.34\t2.28 Zone D\t3.77\t3.71\t2.52\t2.46\tZone D\t3.77 3.71\t2.52\t2.46 Zone F,\t3.99\t3.92\t2.57\t2.50\tZone F.\t3.99 3.92\t2.57\t2.50 Zone F\t4.40\t4.32\t2.76\t2.70\tZone F\t4.40 4.32\t2.76\t2.70 Minimum:\t\t6.50\t\t\tMinimum:\t6.50\t\t Nouveau-Brun\tswick :\t7.25\t\t\tNew Brunswick: 7.25\t\t\t Demande de modification de taux pour le transport de produits pétroliers par camions citernes de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski, Matane et Gaspé à différents points dans la région du bas du fleuve et du Nouveau-Brunswick.Requête pour être relevée du délai de six (6) mois: La requérante demande à la Commission d'être relevée du délai de six (6) mois pour produire une nouvelle demande pour un permis spécial dans le but d'être autorisée à effectuer le transport d'écoliers de 14 à 18 ans résidant dans Longueuil.Laflèche.Ville Lemoyne.Greenfield Park et St-Lainbert, fréquentant l'Ecole Secondaire n Jean-de-la-Mennais » de Laprairie.pour la période scolaire de septembre 1973 à juin 1974.La partie requérante demande l'émission du permis suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'effectuer le transport des écoliers dont l'âge varie de 14 a 18 ans (Cours Secondaire) et demeurant dans les municipalité» de: Longueuil.Laflèche.Ville Lemoyne, Greenfield Park et Si-Lambert fréquentant l'Ecole Secondaire « Jeaii-de-la-Mennais » située au S70.Chemin St-Jean.La Prairie, P.Que., et m pour la période scolaire île septembre 1973 a juin 1974.Request for a modification of rate for the transportation of oil products in tank trucks from Rivière-du-Loup.Trois-Pistoles, Rimouski, Matane and Gaspé to various points in the lower St.Lawrence region and New-Brunswick.Request to be released from the time limit of six (6) months: The applicant requests the Commission to release it from the time limit of six (6) months in order to produce a new application for a special permit authorizing it to provide a transportation service for the pupils aged 14 to 18 residing in Longueuil, Laflèche, Town of Lemoyne, Greenfield Park and St.Lambert, attending the \"Jean-de-la-Mennais\" secondary school in Laprairie, during the school year, that is from September 1973 through to June 1974.The applicant requests delivery of the following permit: Class of permit: Bus service.Service : The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide a transportation service for the pupils aged 14 to 18 years (secondary school) and domiciled in the following localities: Longueuil, Laflèche, Town of Lemoyne, Greenfield Park and St.Lambert, attending the \"Jean-de-la-Mennais\" secondary school, located at 870 St.Jean Road, La Prairie, P.Q.during the school year, that is from September 1973 to June 1974. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année.n° 45 6607 Rôle M-543 21752-V D-2 DELIVRO CANADA INC.179, avenue Brittany, Montréal 304, P.Q.Rôle M-544 21752-VM D-l DELIVRO CANADA INC., 179.avenue Brittany, Montréal 304, P.Q.Parcours à suivre: Service à être donné dans les municipalités de: Longueuil, Ville Lemoyne, Laflèche, Greenfield Park, Préville et St-Hubert, suivant entente avec les autorités municipales.Requête pour obtenir permis permanent.La partie requérante dont la clause d du permis se lit comme suit: Classe: d) Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service: d) De Sherbrooke à Montréal et retour, pour le transport de colis de 50 livres ou moins, avec des camions d'une capacité maximale de trois tonnes et demie.Restrictions: 1) La détentrice ne devra pas accepter d'envois de plus de 200 livres d'un même expéditeur à un même destinataire.2) La détentrice n'aurait pas le droit de transporter les articles ou item suivants: 1 ) microfilms, documents commerciaux, documents et actes (sauf les pièces de monnaie, les devises et les titres négociables).2) Pellicules et épreuves impressionnées et développées, pellicules de remplacement supplémentaires et accessoires s'y rattachant destinés aux détaillants vendant des films et des accessoires photographiques (sauf les films destinés aux cinémas, les accessoires et costumes de théâtre destinés à des théâtres ou en provenant des stations de télévision ou de tous autres centres de spectacle).3) Matériels utilisés dans le traitement des données par ordinateurs, cartes perforées, bandes magnétiques, documents codés et registres de bureau.4) Verres de lunette, montures et lentilles, ainsi que les pièces s'y rattachant.5) Epreuves, clichés, copies et photogravures de documents publicitaires.0) Livres de comptabilité, rapports commerciaux et archives commerciales.Requête pour obtenir permis permanent.La partie requérante dont la clause c du permis se lit comme suit: Classe: c) Transport restreint - longue distance -route -Service: c) De Montréal à la frontière Québec-Ontario (ports d'entrée: Pointe-Fortune et Rivière Beaudette) et retour, pour le transport de colis n'excédant pas 50 Ibs.(Destination: Toronto).Restrictions: 1) La détentrice ne devra pas accepter d'envois de plus de 200 livres d'un même expéditeur à un même destinataire.2) Le service exploité en vertu de cette clause est sujet à la production d'un permis connexe de l'Ontario Highway Transport Board, avant le 1er novembre 1973.Restrictions attachées aux clauses d et e: 1) Les clauses (f et c de ce permis sont expérimentales et valides jusqu'au 1er octobre 1973.2) La requérante devra produire à la Commission à la fin de chaque mois d'exploitation, les statistiques suivantes: a) Nombre de colis transportés durant le mois écoulé.b) Revenu brut obtenu de ce service.Route: This service shall be operated in the following localities: Longueuil, Town of Lemoyne, Laflèche, Greenfield Park, Préville and St.Hubert, as agreed with the municipal authorities.Application for a regular permit: The applicant who holds a permit in which clause d reads as follows: Class: (d) Restricted trucking - long distance -restricted route -Service: (d) From Sherbrooke to Montreal and return, for the transportation of parcels weighing 50 lb or less, in trucks having a maximum capacity of three tons and a half.Restrictions: (1) The holder shall not accept shipments weighing more than 200 lb from a single shipper to a single consignee.(2) The holder shall not be allowed to transport the following goods or items: (1) microfilms, commercial papers, documents and written instruments (excluding coins, currency and negotiable securities).(2) Exposed and processed films and prints, complementary replacement films and incidental supplies hereto for dealers who handle such films and supplies (excluding motion picture films, theatre accessories or confections to and from public theatres, television stations or any other public display centre).(3) Papers used in the processing of data by computing machines, punch-cards, magnetic and encoded documents and office records.(4) Eye glasses, eye, glass frames and lenses and other parts thereof.(5) Advertising proofs, cuts, copy and photo-engraving.(6) Accounting media, business reports and business records.Applicant for a regular permit.The applicant who holds a permit in which clause e reads as follows: Class: e) Restricted trucking - long distance -route -Service: (e) From Montreal to the Québec-Ontario border (Ports of entry: Pointe-Fortune and Rivière-Beaudette) and return, for the transportation of parcels weighing 50 lb.or less (Destination: Toronto).Restrictions: (1) The permit-holder shall not accept shipments weighing more than 200 lb.from a single shipper to a single consignee.(2) The service operated in conformity with the present clause is subject to the filing of a related permit to be issued by the Ontario Highway Transport Board before November 1, 1973.Restrictions attaching to clauses d and c : (1) Clauses d and e of this permit are experimental and valid until October 1, 1973.(2) The applicant shall file the following statistics with the Commission at the end of each month of operation: (a) Number of parcels transported during the past month.(6) Gross income received for this service. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10.1973, Vol.105, No.ho Rôle M-545 23453-VM D-l VEENSTRA VAN LINES INC., 450, Cumberland avenue, Hamilton 22, Ontario.c) Nombre de milles parcourus pour donner ce service.d) Les dépenses d'exploitation de ce service.3) Un mois avant l'expiration de ce permis temporaire, la détentrice devra s'adresser à la Commission pour en obtenir la prolongation ou obtenir qu'il soit rendu permanent.4) À la lumière des statistiques produites, la Commission décidera si ce permis doit être annulé, prolongé ou rendu permanent ou encore, s'il y n lieu d'entendre de nouveau la requérante en séance publique pour complément de preuve.demande à la Commission de rendre une décision déclarant permanente la clause sus-dite du permis de la requérante.Remarque: Si la Commission rend une décision dans le sens indiqué, à l'avenir, la clause t sera opérée conjointement avec le certificat de permis émis par l'Ontario Highway Transport Board, en date du 8 mars 1973.Transport de ménages par fourgons spécialement équipés à cet effet et utilisés exclusivement au transport de ménages, au sens de l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage.1) Transport restreint - longue distance -irrégulier - 1) De la frontière Ontario-Québec a tous les endroits situés au Québec, et retour, (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination ou origine: Manitoba, Ontario.Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les Etats-Unis.2) Transport restreint - longue distance -irrégulier - 2) De tous les endroits situés au Québec à la frontière Québec-Nouveau Brunswick, et retour, et à la frontière Québec-Etats-Lrnis, et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination ou origine; Nouveau-Brunswick et les Etats-Unis.3) Transport restreint - longue distance -irrégulier - en transit - 3) En transit d'une frontière à.toute autre frontière du Québec (via tous les ports d'entrée et itinéraires irréguliers).Destination ou origine: Nouveau-Brunswick, Ontario, M uni tuba.Saskatchewan, ( -olombie-Brh an-nique, Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les Etats-Unis.Restrictions et conditions: 1) Le* clauses 1, 2 et 3 ci-dessus mentionnées seront exploitées avec un certifient complémentaire No X-567 émis par l'Ontario Highway Transport Board le 27 juin 1972 et avec des permis ou des certificats complémentaires devant être émis, selon le cas, par les autres juridictions en cause, et dont une copie devra être déposée à la Commission des transports du Québec.2) Le transport autorisé par les clauses 1, 2 et 3 du présent permis sur les routes du Québec sera effectué dans des fourgons spécialement conçus et aménagés pour les déménagements, et utilisés exclusivement pour le transport de ménages et de meubles usagés, au sens de l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage.3) Le détenteur devra fixer des plaques d'immatriculation de la Commission des transports du Québec sur les véhicules trans|>ortant des ménages.(c) Number of miles covered to provide this service.(d) Operating expenses of this service.(3) One month before the expiry of this temporary permit, the holder shall apply to the Board to obtain an extension of this permit or a regular permit.(4) According to the statistics produced, the Commission will decide if this permit is to be annuled, extended or granted as a regular permit, or, as the case may be, will hear the applicant at a public hearing to complete the evidence.requests the Commission to render a decision to the effect that the aforesaid clause becomes a regular clause of its permit.Note: If the Commission makes the decision stated above, clause e shall henceforth be operated jointly with the permit certificate issued by the Ontario Highway Transport Board, dated March 8.1973.Transportation of household goods, as defined in article 51 of the general Order on trucking, in specially Equipped Moving Vans used exclusively for the transportation of household goods.(1) Restricted trucking - long distance -irregular - (1) From the Ontario-Québec border to all localities situated in the Province of Quebec, and return, (via irregular routes and all ports of entry) destination or origin: Manitoba, Ontario, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, North West and Yukon Territories and the United States.(2) Restricted trucking - long distance -irregular - (2) From all localities situated in the Province of Québec to the Québec-New-Brunswick border and return, and to the routes and all ports of entry) Destination or origin: New Brunswick and the United States.(3) Restricted trucking - long distance -irregular - in transit \u2014 (3) In transit, from any border to any other border of the Province of Québec (via all ports of entry and irregular routes) destination or origin: New Brunswick, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia.North West and Yukon Territories and the LTnited States.Restrictions and conditions: (1) Clauses 1, 2 and 3, above mentioned are to be operated in conjunction with a complementary certificate No.X-567 issued by the Ontario Highway Transport Board on June 27, 1972 and also in conjunction with complementary certificates or permits to the issued by the other jurisdictions referred to therein, as may be required, and copy of which must be filed with the Québec Transport Commission.(2) The transportation authorized by clauses 1, 2 and 3, of the permit over the roads of the Province of Québec, shall be made in sjwcially designed and equipped household goods moving vans used exclusively for the transportation of household goods and second hand furniture as defined by Article 51 of the General Order on Trucking.(3) The permit holder shall have affixed to the vehicles transporting household goods, registration plates of the Québec Transport Commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.n° 45 6609 Rôle M-540 19926-V M D-l TF TRANS CANADA TRANSFER A STORAGE INC., 1725 Basin Street.Montréal 105.P.Q.Rôle M-547 524-V M D-l TF J.B.BA1LLARGEON EXPRESS LTEE, 5045 est, rue Ontario, Montréal 404, P.Q.Rôle M-548 21133-V M D-l TF STACEY'S MOVING (NIAGARA) LIMITED, 6 Bunting Road .Catharines, Ontario.Rôl M-549 20211-V D-l BOWES MOVING & STORAGE LIMITED 8880, Young Road South Chilliwack, British Columbia.Requérante / Applicant.Rôle M-550 2096-A METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC., 1390.rue William.Montréal, P.Que.Requérante / Applicant.4) Le présent permis sera accordé à la conditions expresse que le détenteur ait un bureau d'affaires dans la province de Québec.Le permis sera nul et non avenu si le détenteur établit un entrepôt dans la province de Québec.5) La Commission pourra réexaminer et reviser le présent permis dans l'éventualité où le détenteur cesse d'agir comme voiturier remorqueur pour le compte de Atlas Van Lines (Canada) Ltd.6) En donnant le service autorisé par le présent permis, il est strictement interdit de transporter des meubles et des fournitures non emballés, ainsi que de l'équipement électronique et les pièces s'y rattachant.7) On attire l'attention de la requérante sur les dispositions de l'article 39 de la Loi des transports, stipulant que tout contrat autorisant un changement de contrôle des services donnés doit être approuvé par la Commission.Demande d'une augmentation moyenne de 8% sur les taux présentement déposés.Demande d'augmentation d'environ 15% sur nos taux actuels.Atlas Van Lines (Canada) Ltd., Tarif No 5.Canadian Household Goods Carriers' Tariff Bureau Ass'n, Tarifs numéros NP-50, E-303 et G-4I.Household Goods Carriers' Bureau, Tariff No 64 MF I.C.C.No 59.Annulation de service.La requérante s'est adressée à la Commission pour faire annuler le service ferroviaire suivant: y compris les restrictions et conditions s'y rattachant: Permis de courtier en transport Permis de courtier en transport - longue distance - services ferroviaires - alternative au rayon \u2014 service routier seulement \u2014 De la frontière Québec-Ontario à Montréal et retour, pour le transport de ménages, au sens de l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, en utilisant les services rail-route établis par le C.N.R.et le C.P.R., à destination ou provenant des points situés au-delà des frontières que la requérante est autorisée à desservir.Remarque: La partie requérante maintiendra ses services routiers comme elle l'a été autorisée.La requérante qui opère divers services en vertu de son permis demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: De Montréal à St-Lazare.Parcours: Dans Montréal: D'après entente avec les autorités municipales.Ville St-Pierre et jusqu'à Pointe-Claire: Route No 2 - No 20 et rue Cartier.(4) This permit is granted on the condition that the operator has a place of business in the Province of Québec.This permit will become null and void if the permit holder establishes a warehouse in the Province of Québec.(5) This permit shall be subject to reconsideration and revision by the Commission in the event of the permit holder ceasing to be a hauling agent of Atlas Van Lines (Canada) Ltd.(6) The transportation of new uncrated furniture and fixtures and electronic equipment and parts therefor is strictly prohibited when giving a service in virtue of this permit.(7) The attention of the applicant is drawn to Article 39 of the Transport Act, which requires that any contract effecting a change in control of the authorized services must receive the approval of the Commission.Request an average of 8% increase over rates actually filed.Application for an increase of approximately 15% over our present rates.Atlas Van Lines (Canada) Ltd., Tariff No.5.Canadian Household Goods Carriers' Tariff Bureau Ass'n., Tariffs Numbers NP-50, E-303 and G-41.Household Goods Carriers' Bureau Tariff No.64 MF I.C.C.No.59.Cancellation of service.The applicant has applied to the Commission in order that the following « piggyback\" rail service be cancelled; including the restrictions and conditions attached thereto: Transport broker permit.Transport broker permit - long distance -rail \"Piggyback\" services - alternative to radius - highway service only.From the Québec-Ontario border to Montreal and return, for the transportation of household goods as defined by Article 51 of the General Order on Trucking, by utilizing the scheduled railraod \"Piggyback\" services of the C.N.R.and the C.P.R.to or from all localities situated beyond the said border which the applicant is authorized to serve.Note: The applicant shall maintain its highway services as authorized.The applicant who operates various services according to its permit, requests authorization to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service: From Montreal to St.Lazare.Route: .In Montreal: as agreed with the municipal authorities.Town of St.Pierre up to Pointe-Claire: Highway No.2 - No.20 and Cartier Street. 6610 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Rôle M-551 2472-A FIRST M ES I FT A OF CANADA (Jeno Kelin operating under the name of) : 2325 Ekers Avenue.Montréal.P.Q.Rôle M-552 3537-A D-l TRENHOLME NURSERY, (Mrs Anna Mayer, operating under the name of) : 6720 Sherbrooke St., West, Montréal, P.Q.Rôle M-553 2766-A-D-l FRANCOIS BELAND, ENR'C, (Monsieur François Béland, opérant sous le nom de) : 555S, rue Aubin, Montréal-Nord.(461) P.Que.Pointe-Claire :\\ Ste-Anne de Bellevue, via route 37.Ile Perrot, Dorion, Vaudreuil et ensuite vers St-Lazare, via route 340, Chemin St-Louis.Montée Chevrier et Chemin Ste-Evangélique.Conditions et restrictions: 1) Pas de service local dans et entre les municipalités de Vaudreuil et Dorion.2) Pas de service local sur les parcours desservis par la Commission de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal.La requérante demande l'autorisation de fournir les services suivants: Classe de permis: Service d'autobus.Service No 1 : Transport d'écoliers âgés de moins de huit (8) ans, de leur domicile a « First Mesifta of Canada « (Jewish Talmudical College), 2325 avenue Ekers.Montréal 256, P.Q., et retour.Territoire: Pourront être transportés les enfants résidant dans le quadrilatère borné par les rues suivantes: Nord: Jean-Talon, sud: Sherbrooke, est: St-Denis, ouest: Côte St-Luc.Service No 2: Transport de personnes âgées et malades devant être accompagnées par des personnes en santé, de leur résidence situées à Montréal.Westmount et Côte St-Luc à o Maimonides Hospital and Home for the Aged », et retour.Ces personnes âgées sont conduites tous les jours à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux spéciaux.Ce transport est effectué par l'hôpital ci-dessus mentionné qui en défraie également le coût.Territoire: Nord: rue Anvers, sud: avenue des Pins, est: avenue du Parc, ouest: Côte St-Luc.La requérante demande l'autorisation de fournir le service suivant: Classe du permis: Service d'autobus.Service: Transport d'écoliers âgés de deux (2) à cinq (5) ans résidant dans Montréal et se rendant à n Trenholme Nursery I située au 6720 ouest, rue Sherbrooke, Montréal.P.Q., et retour.Territoire: Ce service sera donné dans Montréal et dans le quadrilatère borné par les rues suivantes: Nord: chemin de la Côte St-Luc, ouest: avenue Westminster, sud: chemin Upper Lachine, est: avenue At water.Conditions et restrictions: 1) La détentrice devra maintenir en vigueur pour la protection des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No 5448 de la Régie des transports en date du 21 juin 1963.Le requérant demande à la Commission l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : Transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans, de leur domicile situé dans le territoire ci-après décrit et se rendant aux écoles maternelles suivantes, et retour: Pointe-Claire to Ste.A nne-de-Bel levue-via Highway 37.Ile Perrot, Dorion, Vau, dreuil and from there towards St.Lazare via Highway 340, St.Louis Road, Montée Chevrier and Ste.Evangélique Road.Conditions and restrictions: (1) There shall be no local service in and between the municipalities of Vaudreuil and Dorion.(2) There shall be no local service on the routes served by the Montreal Urban Transit Commission.The applicant is asking for authorization to give the following services: Class of permit: Autobus service.Service No.1: Transportation of school children under eight (8) years of age from their home to the \"First Mesifta of Canada\" (Jewish Talmu-dical College) 2325 Ekers Avenue, Montréal 256, P.Q.and return.Territory: The children to be transported residing in the District bounded by the following streets: North: Jean-Talon, south: Sherbrooke, east: St-Denis, west: Côte St-Luc.Service No.2: Transportation of aged and sick persons who must be accompanied by normal persons from their residence situated in Montreal, Westmount and Côte St-Luc to the \"Maimonides Hospital and Home for the Aged\", and return.These aged persons are brought daily to the Hospital to receive special medical cares.This transport is made and paid for by the above-mentioned Hospital.Territory: North: Anvers Street, south: Pine Avenue, east: Park Avenue, west: Côte St-Luc.The applicant is asking for authorization to give the following service: Class of permit: Autobus Service.Service: Transportation of school children between two (2) and five (5) years of age residing in Montreal and attending the \"Trenholme Nursery situated at 6720 Sherbrooke St., West, Montreal, P.Q.and return.\" Territory: This service will be given in Montreal, in the territory bounded by the following streets: North: Côte St-Luc Road, west: Westminster Ave., south: Upper Lachine Road, east: Atwater Avenue.Conditions and restriction: (1) The permit holder shall maintain in force, for the protection of transported children, a legal responsibility insurance, in conformity to the dispositions of the Transportation Board General Order No.5448 dated June 21st, 1963.The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service : Transportation of children aged three (3) to seven (7) from their homes located in the territory described below, and attending the following kindergartens, and return: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6611 Rôle M-554 U23-A-D-1 ST-LEONARD TRANSPORT ENR'C, (Monsieur Jean Vanier, opérant sous le nom de) : \"900, Boul.Métropolitain.Montréal, P.Que.Ecole Privée & Maternelle Leblanc Ltée.7324, rue Musset, Montréal (453) P.Q.Académie St-Louis de France, 2451 Avenue Elsdale, Montréal.P.Q.Our Lady of Charity School, 2651 boulevard Métropolitain.Montréal, P.Q.St-Thomas à BecJcet School, 2650 est, rue Jarry, Montréal.P.Q.Gerald McShane, 6111 boul.Maurice Du-plessis, Montréal-Nord, P.Q.Ste-Gertrude, 11,813 rue Ste-Gertrude, Montréal-Nord, P.Que.Frédéric Ozanam, 12,001 rue Jean-Paul Cardinal.Montréal-Nord.P.Q.Ste-Colette, 11,960, boul.Ste-Colette, Montréal-Nord.P.Q.Loisirs Ste-Gertrude.11,833, rue Lamou-reux.Montréal-Nord, P.Q.Territoire: Les enfants à être transportés résidant dans le territoire borné par les rues suivantes: Nord: boul.Gouin.ouest: rue Ste-Denis, sud: rue Sherbrooke est: Ray Lawson (Roi-René).Conditions et restrictions: 1) Ce service ne sera donné que pour la période scolaire soit de septembre 1973 à juin 1974.2) Le détenteur devra maintenir en vigueur, pour la protection des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No 5448 de la Régie des transports, en date du 21 juin 1963, Le requérant demande à la Commission l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans.de leur résidence située dans les municipalités d'Outremont, Ville Mt-Royal.St-Laurent et Montréal et fréquentant « l'Ecole Sepharade de Montréal » située au 6567 Trans-Island Avenue, Montréal, P.Qué.et ce de septembre 1973 à juin 1974.Condition et restriction: 1) Le détendeur devra maintenir en vigueur, pour la protection des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No.5448 de la Régie des transports, en date du 21 juin 1963.Ecole Privée & Maternelle Leblanc Ltée, 7324 Musset St., Montreal 453, P.Q.Académie St-Louis-de-France.2451 Els-dalo Ave., Montreal, P.Q.Our Lady of Charity School, 2651 Métropolitain Blvd.Montreal, P.Q.St-Thomas to Becket School.2660 Jarry St.East, Montreal, P.Q.Gerald McShane, 6111 Maurice Duplessis Blvd., Montreal-North, P.Q.Ste-Gertrude.11,813 Ste.Gertrude St., Montreal-North, P.Q.Frédéric Ozanam, 12.001 Jean-Paul Cardinal St., Montreal-North.P.Q.Ste-Colette, 11,960 Ste.Colette Blvd., Montreal-North.P.Q.Loisirs Ste-Gertrude, 11.833 Lamoureux St., Montreal-North, P.Q.Territory: The children to be carried are domiciled in the territory bounded by the following streets: North: Gouin Blvd., west: St.Denis St., south: Sherbrooke St.east.Ray Lawson (Roi-René).Conditions and restrictions: (1) This service shall be given only during the school year, that is from September 1973 to June 1974.(2) Pursuant to the provisions of General Order No.5448 of the Transportation Board, dated June 21.1963, the permit-holder shall maintain a public liability insurance for the protection of the children carried.The applicant requests from Commission the authorization to provide the following service: Class of permit : Bus service.Service: Transportation of children aged three (3) to seven (7), from their residences located in the municipalities of Outremont, Town of Mount-Royal, St.Laurent and Montreal, to the \"Ecole Sepharade de Montréal\" located at 6567 Trans-Island Avenue, Montreal, P.Q., from September 1973 to June 1974.Condition and restriction: (1) Pursuant to the provisions of General Order No.5418 of the Transportation Board, dated June 21, 1963, the permit-holder shall maintain a public liability insurance for the protection of the children carried.Rôle M -555 2094-A AUTOBUSFRANCOEUR 9795, 38ième Avenue, Riviere-des-Prairies, Montréal 477.P.Q.Le requérant demande à la Commission l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'écoliers handicapés de leur résidence située dans Longueuil, Verdun, St-Laurent, Outremont, Ville Laval, Montréal-Nord, Ville d'Anjou.St-Léonard, Montréal Est, Pointe-aux-Trembles, et Montréal et se rendant a la « Maternelle Marie-Claire Fournier et le Centre Académique Founder, situés au 12,550 boul.Lacordaire, Montréal-Nord et retour.» Les autobus sont a la dispesition de ladite école toute la journée pour répondre aux besoins de cette dernière.Condition et restriction: Le requérant devra maintenir en vigueur, pour la protection des enfants transportés.The applicant requests from the Commission the authorization to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service: Transportation of handicapped pupils from their homes located in Longueuil, Verdun, St.Laurent.Outremont, City of Laval, Montreal-North, Town of Anjou, St.Léonard, Montreal-East, Pointe-aux-Trembles and Montreal, and attending Maternelle Marie-Claire Fournier and Centre Académique Fournier located at 12,550 Lacordaire Blvd.Montreal-North, and return.The busses shall be at the disposal of said school all day long in order to meet thelatter's needs.Condition and restriction: Pursuant to General Order No.5448 of the Transportation Board, dated June 21.1963, Of) 12 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.106.No.45 Rôle M-556 15441-V M.GAUVIN TRANSPORT ENRG., (Marcel Gauviu operant sous re nom) : 781 A.Ogilvie, Montreal 303, P.Q.une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No.5448 de la Régie des transports, en date du 21 juin 1963.Cession de la propriété du système de transport (suite a la demande d'incorporation du requérant-cédant).La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de céder la propriété du système de transport qu'elle exploite à Les Transports Gauvin inc.- Gauvjn Transport Inc.dont elle possède la majorité des actions et dont le siège social sera au même endroit, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi du trans|K>rt.the permit-holder shall maintain a public liability insurance for the protection of the children carried.Transfer of ownership of the transport service (following the applicant-vendor's application for incorporation).Pursuant to the provisions of section 39 of the Transport Act, the applicant-vendor requests authorization from the Commission to transfer the ownership of the transport service it operates at Les Transports Gauvin inc.-Gauvin Transport Inc.in which it holds the majority of shares and whose head office shall remain at the same address.Hole M -557 4007-V BEAUDRY, JEAN-PAUL, 910, rue Dupont, St-Césaire.rte Rouvilln, P.Q.et / and BELLAVANCE, JULIEN, St-Angèle de Monnoir, Cté Rouville, P.Q.Requérantes / Applicants.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation décédera: Bellavance, Julien.Ste-Angèle-de-Monnoir, Cté Itonville.P.Q.la propriété du système de transport suivant: Permis 4007-V\" Transport général : a) St-Césaire et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville.6) De St-Césaire à tous les endroits situés dans un rayon de trente milles des limites de ladite municipalité et retour.Transfer of ownership of the transport service (sale).The applicant requests authorization to transfer to: Bellavance.Julien, Ste.Angèle-de-Mon-noir.Rouville County, P.Q.the property of the following transport service: Permit 4007-V General trucking: (a) St.Césaire and all points located within a distance of five miles from the limits of said Town.(4) From St.Césaire to all points located within a radius of thirty miles from the limits of said Town and return.Rôle M-558 12518-V.M CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS, Tariff Bureau Ass'n.4180 Dundas Street.Toronto.Ontario.M8X 1X8 (pour / on behalf of A & F BAILLARCEON EXPRESS ONT.INC.i.7 Kenhar Dr.Weston.Ont.Rôle M-559 22908-V-D-l ZAKAIB CARTAGE REG'D., (Emile Zakaib opérant sous le nom de» 6035.rue Toulouse, Montréal, Que.Rôle M-560 1344-V BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., Edifice Girardin, suite 400.1259, rue Berri, Montréal 132.P.Q.(pour/on behalf of HUSBAND TRANSPORT LTD.), permis No 1344-V.Supplément No 43 au tarif No 143-A, MF-I.C.C.No 159 applicable aux expéditions d'un endroit à un autre au Canada, d'une part, et à des endroits situés aux Etats-Unis, d'autre part.Supplement No.43 to tariff No.143-A.MF-I.C.C.No.159 which applies on shipments between points in Canada on the one hand, and, on the other, points in the United States.Cession de la propriété du système de transport (vente).Gérard M.Perreault Inc.18088-V Air Cargo Bldg.Aéroport de Montréal, Ch.114 Dorval.Pointe-Claire (Dorval) 300, Que.la propriété du système de transport suivant : Permis No 22908-V Transport général - service local -Ville de Laval et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite localité.Demande de fixation de taux.Modification du Supplément Intérim No 1948.Addition de certains taux horaires et hebdomadaires pour transport effectué dans Montréal et un rayon de 5 milles.Transfer of ownership of the transport service (sale).Gérard M.Perreault Inc.18088-V Air Cargo Bldg.Montreal Airport.Room 114 Dorval, Pointe-Claire (Dorval) 300, Quebec.ownership of the following transport service: Permit No.22908-V General trucking - local service -City of Laval and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said locality.Application for fixing of rate.Modification of Interim Supplement No.1948.Addition of certain hourly and weekly rates for transportation provided in Montreal and within a radius of 5 miles. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105e année, nc 45 6613 Rôle M-561 20051-V BOUCHARD, GERARD, 7753.Lecourt, Montréal 429.P.Q.Requérante / Applicant.Rôle M-562 NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC., P.O.Box 184.Buffalo.N.Y.1422! Rôle M-563 20426-V (Martel) 520-V (St-John's) R.MARTEL EXPRESS LIMITEE et/and ST-JOHN'S EXPRESS LIMITED, the / les mises en cause COMMUTEX INC., Requérante-cédante / Applicant-transierrer, TRUST GENERAL DU CANADA, Requérante-cessionnaire / Applicant-transferee.Rôle M-564 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS, Tariff Bureau Ass'n., 4180 Dundas Street, Toronto, Ontario.M8X 1X8 (Pour/on behalf of BOWEN MOVING & STORAGE LTD.), P.O.Box 551.Chatham, Ont.N7M 5K6 Annulation de permis.La partie requérante demande l'annulation de son permis qui se lit comme suit: Classe : Transport restreint - local - contrat -Service: District Métropolitain de Montréal, pour le transport de papeterie, pour le compte de la Papeterie Brel Limited de Montréal.Demande de fixation de tarif.Modification des taux au tarif 478-A, tel qu'il appert à l'émission du tarif 478-B.Cession de la propriété du système de transport (suite à la cession du contrôle des actions majoritaires).En vertu de l'article 39 de la Loi des transports, la requérante-cédante, Commutex Inc., a demandé à la Commission des transports d'autoriser le nantissement, la mise en gage, la cession et le transport des cinquante et une (51) actions qu'elle détient dans R.Martel Express Limitée et des cent actions (100) qu'elle détient dans St.John's Express Limited, ces dernières étant les compagnies mises en cause, en faveur de Trust Général du Canada, aux termes d'un acte d'hypothèque, de nantissement et de gage consenti en date officielle du 1er septembre 1973, par les compagnies mises en cause, en faveur de Trust Général du Canada, es-qualité de fiduciaire.Distribution actuelle des actions des compagnies mises en cause: R.Martel Express Limitée: Commutex Inc.51 actions ord.J.-Edouard Fleury 1 action ord.Claude Perron 1 action ord.Pierre Jolin 1 action ord.St-John's Express Limited: Commutex Inc.100 actions ord.J.-Edouard Fleury 1 action ord.Claude Perron 1 action ord.Pierre Jolin 1 action ord.Distribution future des actions des compagnies mises en cause: R.Martel Express Limitée: Trust Général du Canada, ès-qualité de fiduciaire: 51 actions ord.J.-Edouard Fleury 1 action ord.Claude Perron I action ord.Pierre Jolin 1 action ord.St-John's Express Limited: Trust Général du Canada, es-qualité de fiduciaire: 100 actions ord.J.-Edouard Fleury 1 action ord.Claude Perron 1 action ord.Pierre Jolin 1 action ord.Supplément No 34 au tarif No.144-C MF-LC.C.No 160 applicable aux expéditions d'un endroit à un autre au Canada, d'une part, et à des endroits situés aux Etats-Unis, d'autre part.Cancellation of permit.The applicant requests the cancellation of its permit reading as follows: Class: Restricted trucking - local - contract -Service: Metropolitan District of Montreal, for the transportation of stationery, on behalf of Papeterie Brel Limited of Montreal.Application for fixation of tariff.Modification of rates in tariff 478-A as reflected in the issuance of tariff 478-B.Transfer of ownership of the transport service (further to transfer of control of the majority of shares).Pursuant to section 39 of the Transport Act, the applicant-transferrer, Commutex Inc., has requested from the Transport Commission the authorization to pledge, pawn, assign and transfer the fifty-one (51) shares it holds in R.Martel Express Limitée and the one hundred (100) shares it holds in St-John's Express Limited, the latter being the companies mises en cause, in favour of General Trust of Canada, under the terms of a deed of mortgage, pledge and pawning executed on the official date of September 1.1973.by the companies mises en cause, in favour of General Trust of Canada, in its capacity as trustee.Present allotment of shares of the companies mises en cause: R.Martel Express Limitée: Commutex Inc.51 common shares J.Edouard Fleury 1 common share Claude Perron 1 common share Pierre Jolin I common share St-John's Express Limited: Commutex Inc.100 common shares J.Edouard Fleury 1 common share Claude Perron 1 common share Pierre Jolin 1 common share Future allotment of shares of the companies mises en cause: R.Martel Express Limitée: General Trust of Canada, in its capacity as trustee: 51 common shares J.Edouard Fleury I common share Claude Perron 1 common share Pierre Jolin I common share St-John's Express Limited: General Trust of of Canada, in its capacity as trustee: 100 common shares J.Edouard Fleury 1 common share Claude Perron 1 common share Pierre Jolin 1 common share Supplement No.34 to tariff No.144-C MF-I.C.C.No.160 which applies on shipments between points in Canada on the one hand, and.on the other, points in the United States. 6614 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Rôle M-565 3448-A D-l MONSIEUR UBALD AQUIN, 363.rue St-Régis, St-Roch de l'Achigan, P.Que.Requérante / Applicant.Rôle M-566 13963-V-D-4 SPEEDWAY EXPRESS LTD., 20 boul.Marie-Victorin, Boucherville, Cté Chambly.Requérante / Applicant.Rôle M-567 23461-V-D-3 LEO DURAND, Rang Hétrière, St-Charles, Cté Bellechasse.Requérante / Applicant.Rôle M-568 PRIMEAU, BERNARD.100, chemin Notre-Dame, Ste-Adèle, Comté Terrebonne, P.Q.Permis No 2070-A-P-l Rôle M-569 PROVINCIAL OIL CARRIERS COMPANY LIMITED, 6360 est, rue Notre-Dame, Montréal 427, P.Q.Permis No 10934-V Le requérant qui détient un permis l'autorisant à donner, entre autres le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : Transport d'écoliers, à l'heure du midi seulement, résidant dans St-Roch-de-l'Achi-gan et fréquentant l'école polyvalente de St-Roch-de-l'Achigan, et retour.Demande une modification de son permis pour qu'il se lise, à l'avenir, comme suit: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'éooliers.à l'heure du midi seulement, résidant dans St-Roch-de-l'Achi-gan, l'Epiphanie et Ville des Laurentides et fréquentant l'école polyvalente de St-Roch-de-l'Achigan, et retour.Conditions et restrictions: 1) Ce service est réservé exclusivement au transport d'enfants, à l'heure du midi, de leur résidence et se rendant à l'école polyvalente de St-Roch-de-l'Achigan, et retour.2) Le détenteur devra maintenir en vigueur, pour la protection des enfants transportés, une assurance de responsabilités légales, conformément aux dispositions de l'Ordonnance générale No 5448 de la Régie des transports, en date du 21 juin 1963.Modification de permis (courtier).La partie requérante demande le permis suivant : Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par la clause a de son permis No 13963-V, en utilisant le service de remorquage de: Léo Durand, Rang Hétrière, St-Charles, Cté Bellechasse.23461-V.Demande de permis de remorquage.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat - Remorquage avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon la clause a du permis No 13963-V, pour le compte de: Speedway Express Ltd., 20, boul.Marie-Marie-Victorin, Boucherville, Cté Chamblv.13963-V.La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Relativement au cautionnement de $50.00 déposé avec son opposition il une demande de permis spécial de « Les Autobus Caron & Laurin Limitée », permis 2661-A.La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement No 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Relativement au dépôt de $50.00 fait par la requérante avec sa demande apparaissant dans le Bulletin volume 1, numéro 16, requête 12 et dans la Gazelle officielle No 28 The applicant who holds a permit authorizing him to provide, among others, the following service: Class of permit : Bus service.Service: Transportation of students, at noon time only, residing in St.Roch-de-l'Achigan and attending the polyvalent School of St.Roch-de-l'Achigan, and return.Requests a modification of his permit so that it may read henceforth as follows: Class of permit: Bus service.Service: Transportation of students, at noon time only, residing in St.Roch-de-l'Achigan, l'Ephiphanie and the City of St.Laurent and attending the polyvalent School of St.Roch-de-l'Achigan, and return.Conditions and restrictions: (1) This service shall be reserved exclusively to the transportation of students, at noon time, from their homes and attending the polyvalent School of St.Roch-de-l'Achigan.and return.(2) Pursuant to the provisions of General Order No.5448 of the Transportation Board, dated June 21, 1963, the holder shall maintain a public liability insurance for the protection of the students transported.Modification of permit (broker).The applicant requests the following permit: Transport broker service for the transportation of goods authorized under clause a of its permit No.13963-V, utilizing the haulaway service of : Léo Durand, Hétrière Range, St- Charles, County of Bellechasse.23461-V.Application for haulaway permit.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation only - contract - To haul empty or loaded trailers with its duly-registered tractors, according to clause a of its permit No.13963-V, on behalf of: Speedway Express Ltd., 20 Marie-Victo-rin Boulevard, Boucherville, County of Chambly.13963-V.The Commission gives notice of its intention to render a decision on the following matter in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.With respect to a deposit of $50.00 filed with its opposition to an application for a special permit from \"Les Autobus Caron & Laurin Limitée\", permit 2661-A.The Commission gives notice of its intention to render a decision on the following matter in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation No.2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.With respect to a deposit of $50,00 by the applicant with its application appearing in the Bulletin, Volume 1, number 16, application 12 and in the Québec Official Gazelle GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n' 1,5 6615 Rôle M-570 MONTREAL OIL CARRIERS INC., 6360 est.rue Notre-Dame, Montréal 427, P.Q.1743S-V Rôle M-571 1252-DY CH.LOCATIONS LTEE CH.ALL RENTALS LTD.3244 est, rue Beau bien, Montréal 408.P.Q.54434-0 du 14 juillet 1973 et dont la décision MCS-163 a été signifiée le 17 septembre 1973.La Commission donne avis qu'elle entend décider de_ l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement No 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Relativement au dépôt de 850.00 fait par Provincial Oil Carriers Company Limited avec la demande au nom de Montreal Oil Carriers Inc.aparaissant dans le bulletin volume 1, numéro 16, requête 13 et dans la Gazette officielle numéro 28 du 14 juillet 1973 et dont la décision MCS-164 a été signifiée le 17 septembre 1973.La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement No 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Relativement à une correction de la décision signifiée à la requérante le 31 août 1973 par laquelle on décrète la remise de la somme de $75.00 alors qu'un montant de 825.00 seulement avait été déposé avec la requête.number 28.dated July 14, 1973, on which decision MCS-163 was notified on September 17, 1973.The Commission gives notice of its intention to render a decision on the following matter in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.With respect to a deposit of $50.00 by Provincial Oil Carriers Company Limited with the application on behalf of Montreal Oil Carriers Inc., appearing in the Bulletin, Volume 1, number 16, application 13 and in the Quebec Official Gazette number 28, dated July 14, 1973, on which decision MCS-164 was notified on September 17, 1973.The Commission gives notice of its intention to render a decision on the following matter in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation No.2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.With respect to a correction of the decision notified to the applicant on August 31, 1973.in which the remittance of the sum of $75.00 is decreed, while an amount of $25.00 only has been deposited with the application.Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi Avis 1° Le présent avis s'adresse à toute personne qui, par prète-nom : a) Détient pour elle-même, en date du 1er novembre 1973, un permis de propriétaire de véhicule-taxi délivré avant le 9 juillet 1972 en vertu d'un règlement municipal; 6) Détient, en date du 1er novembre 1973, un permis visé au paragraphe a en vertu d\"un transfert dûment autorisé, depuis le 9 juillet 1972.par l'autorité municipale compétente; ou c) Est propriétaire d'un véhicule-taxi dont le numéro d'immatriculation pour l'année 1972 comprend le préfixe « TV ».2° Toute personne visée au paragraphe 1 doit présenter une requête pour l'obtention d'un permis de propriétaire de véhicule-taxi devant la Commission des transports du Québec à: 880, chemin Ste-Foy, Québec 6, P.Q.ou à : 800 est, boul.De Maisonneuve, 7e étage, Montréal 132, P.Q.avant le 1er janvier 1974.3° À défaut par toute telle personne à laquelle il est référé ci-dessus de présenter sa requête d'ici la date mentionnée plus haut, elle ne pourra bénéficier des dispositions du chapitre VII du Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi relativement à l'attribution prioritaire de certains permis de propriétaire.Commission des transports du Québec, Regulation 6 respecting transport by taxicab Notice 1.This notice is to every person who, by prête nom: (a) holds on his own behalf, on the date of 1 November 1973, a taxicab owner's permit issued before 9 July 1972 under a municipal by-law; (6) holds, on the date of 1 November 1973, a permit contemplated in subparagraph a under a duly authorized transfer, since 9 July 1972, by the competent municipal authority; or (c) is the owner of a taxicab whose registration number for the year 1972 includes the prefix \"TV\".2.Every person contemplated in paragraph 1 shall submit an application for the obtaining of a taxicab owner's permit to the Québec Transport Commission at: 880.Ste.Foy Road, Québec 6, P.Q.or 800 east, De Maisonneuve Blvd.7th Floor, Montreal 132, P.Q.before 1 January 1974.3.Failure of every such person abovementioned to submit his application before the above prescribed date shall preclude such person from the benefit of the provisions of Chapter VII of Regulation 6 respecting transport by taxicab in respect of priority in the allocation of certain owners' permits.Québec Transport Commission, 54434-0 Maurice Ferland, l.l.l., Administrateur.54434-0 Maurice Ferland, l.l.l.Administrator. 6616 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10, 1973, Vol.105, No.45 Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi Avis 1 ° Le présent avis s'adresse à toute personne qui : a) Détient en son nom et pour elle-même, en date du 1er novembre 1973.un permis de propriétaire de véhicule-taxi délivré avant le 9 juillet 1972 et en vertu d'un règlement municipal; 6) Détient, en date du 1er novembre 1973, un permis viaé au paragraphe a en vertu d'un transfert dûment autorisé, depuis le 9 juillet 1972, par l'autorité municipale compétente; ou c) Est propriétaire d'un vehiculc-taxi dont le numéro d'immatriculation pour l'année 1972 comprend le préfixe « TV ».2° Toute personne visée au paragraphe 1 doit présenter une requête pour l'obtention d'un permis de propriétaire de véhicule-taxi devant la Commission des transport du Québec à: 880.chemin Ste-Foy.Québec 6, P.Q.ou à : 800 est, boul.De Maisonneuve, 7e étage, Montréal 132, P.Q.avant le 1er janvier 1974.3° A défaut par toute telle personne à laquelle il est référé ci-dessus de présenter sa requête d'ici la date mentionnée plus haut, elle ne pourra bénéficier des dispositions du chapitre VII du Règlement 6 sur le transport par véhicule-taxi, relativement à l'attribution prioritaire de certains permis de propriétaire.Commission des transports du Québec, Maurice Ferland, l.l.l., 54434-0 Administrateur.Regulation 6 respecting transport by taxicab Notice 1.This notice is to every person who: (a) holds, in his own name and on his own behalf, on the date of 1 November 1973, a taxicab owner's permit issued before 9 July 1972 under a municipal by-law ; (6) holds, on the date of 1 November 1973, a permit contemplated in subparagraph a under a duly authorized transfer, since 9 July 1972, by the competent municipal authority; or (c) who is the owner of a taxicab whose registration number for the year 1972 includes the prefix \"TV\".2.Every person contemplated in paragraph 1 shall submit an application for the obtaining of a taxicab owner's permit to the Québec Transport Commission at: 880, Ste.Foy Koad, Québec 6, P.Q.or 800 east.De Maisonneuve Blvd.7th Floor, Montreal 132, P.Q.before 1 January 1974.3.Failure of every such person abovementioned to submit his application before the above prescribed date shall preclude such person from the benefit of the provisions of Chapter VII of Regulation 6 respecting transport by taxicab in respect of priority in the allocation of certain owners' permits.Québec Transport Commission, Maurice Ferland.l.l.l., 54434-0 Administrator.V \u2014 Avis des décisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la lévision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\t\tKequérants\t\t\t\tCause\t \tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-381\t23-10-73\t22370-V\t\t\t\t\t MCfl-382\t\tROBERT RICHER INC.\t1-1-62\t2541\t28-4-73\tM-4201\tRejetée / Rejected \t23-10-73\t23105-V\t\t\t\t\t M('H\t\tCLAUDE GRONDIN\t1-1-25\t2525\t28-4-73\t4217\tRejetée / Rejected \t23-10-73\t16886-V WELLIE FORTIER Requérant-vendeur\t\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser ROLAND COTE\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t MCK 3SN\t26-10-73\tApplicant-purchaser 2195-V\t1-1-21\t2522\t28-4-73\t4198\tRejetée / Rejected \t\tHAROLD STARK\t1-1-91\t2552\t28-4-73\tM-4197\tAccordée telle qu'amendée / Granted as amended GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année.n\" 45 6617 No Date Requérants Applicants Bulletin G.O.Q.page date Cause Case Décisions QCR-299 25-10-73 MCS-33 MPV-73 ML-140 25-10-73 25-10-73 25-10-73 QPV-119 25-10-73 17064-V HARVEY TRANSPORT LTEE TREMBLAY EXPRESS LTEE Requérantes / Applicants R.GIRARD TRANSPORT LTEE Intimée / defendant Demande de vérification des services de transport fournis par l'intimé / Request for verification of transport services provided by the defendant.331-V MC CRUM TRANSPORT 22473-V EDMOND SWEENEY 759-DY A.B.C.A.AUTO LOUE POUR EXAMEN DE CONDUITE Requérante / .4ppftcant 982-DY VILLE EMARD RENT A CAR Intimée / defendant.Requête en revision de la décision en chambre rendue No: ML-103 le4 Septembre 1973 / Request on revision of the decision^ rendered in Chamber Xo.ML-103 on September 4, 1973 2510-A VISITE TOURISTIQUE DE QUEBEC INC.Requérante / Applicant CURTIS J.SOMMER-VILLE Intimé / defendant 1-8-6 1-1-74 1-1-117 2942 2547 2561 12-5-73 28-4-73 28-4-73 2438 M-4200 4196 1-14-114 3890 5365 30-6-73 15-9-73 1-11-122 3385 2-6-73 2395 Révocation de permis No 17064-V de l'intimée / Revocation of permit Xo.170S/,-V of the defendant Rejetée ' Rejected Rejetée / Rejected Annulation de la décision du 4 septembre 1973 et permission accordée au requérant de produire une opposition à la demande de l'intimé dans un délai de vingt et un jours (21) de la date de publication de la présente décision / Annulment of the decision rendered on September 4, 1973, and permission granted to the applicant to file an opposition to the defendant's request within a time limit of twenty-one (SI) days from the date of publication of this decision.1) La Commission donne acte à la décision incidente à l'effet que la lettre du 12 janvier 6618 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 No\tDate\tRequérants A pplicants\tBulletin\t< page\t3.O.Q.date\tCause Case\tDécisions \t\t\t\t\t\t\t1973 adressée par la Régie des transports à l'intimé n'a aucun effet en regard du permis détenu par l'intimé.2) La Commission réécrit le permis de l'intimée pour corriger l'erreur contenue dans la décision QPV-26 du 10 juillet 1973.1.The Commission gives notice of the decision incidental to the letter dated January 13, 1973, mailed by the Transport Board to the defendant is null and void with respect to the permit held by the defendant.2.The Commission rewrites the permit of the defendant to correct the error in the decision QPV-26 dated July 10, 1973.SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IX CHAMBERS MCR-375-TF\t19-10-73\t2096-A METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.Demande de modification de tarifs / A pplication for mo-\t\t\t\t\t \t\tdification of tariffs\t\t4915\t25-8-73\tM-119\tAccordée / Granted MCR-376-TF\t19-10-73\tNIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.Demande de modification de tarifs / Application for mo-\t\t\t\t\t \t\tdification of tariffs\t\t5086\t1-9-73\tM-144\tAccordée / Granted MCR-377-TF\t19-10-73\tFINE ART SERVICES TRANSPORT LTD.Demande de modification de tarifs / Application for mo-\t\t\t\t\t \t\tdification of tariffs\t\t4797\t18-8-73\tM-78\tAccordée / Granted MCR-37S-TF\t19-10-73\tBUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Demande de modification de tarifs / A pplicnlion for modification of tariffs MD -4.6956-TFM.5960-TFM, 59S2-83-TFM.5985-89-TFM, 6011-\t\t5084 5085\t\t\t \t\t13-TFM.\t\t5086\t1-9-73\tM-122\tAccordée / Granted MCR-379-TF\t19 10-73\tBUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Demande de modification de tarifs / Application for mo-\t\t\t\t\t \t\tdification of tariffs\t\t5085\t1-9-73\tM-128\tAccordée / Granted MCR-380-TF\t19-10-73\tALLSTRAN EXPRESS LTD.Demande de modification de tarifs / Application for mo-\t\t\t\t\t \t\tdification of tariffs\t\t5084\t1-9-73\tM-123\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, b\" 45 6619 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-384\t23-10-73\t20920-V\t\t\t\t\t \t\tLLOYD EDISON BAKER Requérant-vendeur / Applicant-vendor CADLINE TRANSPORT LTD.Requérant-acquéreu r ,' .4 p-\t\t\t\t\t \t\tpticant-purchaser\t1-16-24\t4124\t14-7-73\t\tAccordée / Granted MCR-385-TF\t23-10-73\t3291-V J.A.DORE TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT INC.\t\t5086\t1-9-73\tM-142\tAccordée / Granted MCR-386-TF\t24-10-73\t6014-TFM MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE,\t\t\t\t\t \t\tAGENT\t\t5086\t1-9-73\tM-143\tAccordée / Granted MCR-387-TF\t24-10-73\t5349-TFM MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE.\t\t\t\t\t \t\tAGENT\t\t4789\t18-8-73\tM-26\tAccordée / Granted QCR-295-TF\t22-10-73\t19304-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tST-LAMBERT TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT INC.\t\t4793\t18-8-73\tQ-51\tAccordée / Granted QCR-296-TF\t23-10-73\t22704-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tCOURRIER TRANS-\t\t\t\t\t \t\tQUEBEC INC.\t\t4793\t18-8-73\tQ-58\tAccordée / Granted QCR-297-TF\t23-10-73\t19296-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tBEL-MONT TRANSIT\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4806\t18-8-73\tQ-50\tAccordée / Granted QCR-298-TF\t23-10-73\t22704-V-D-2\t\t\t\t\t \t\tCOURRIER TRANS-\t\t\t\t\t \t\tQUEBEC INC.\t\t4791\t18-8-73\tQ-37\tAccordée / Granted QCR-300\t25-10-73\tQ-32-V-D-1\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT DALLAI RE\t\t\t\t\t \t\tLIMITEE\t\t4916\t25-8-73\tR.Q.63\tAccordée / Granted QCR-301\t25-10-73\t15-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT D'ANJOU\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4928\t25-8-73\tQ-101\tAccordée / Granted QCR-302\t25-10-73\t23391-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tCAMILLE MARQUIS\t\t4929\t25-8-73\tQ-109\tAccordée / Granted QL-63\t19-10-73\tTRANSPORT THI-\t\t\t\t\t \t\tBAULT INC.\t1-1-9\t2518\t28-4-73\t\tAccordée / Granted QL-64-TF\t25-10-73\t1216-DY et/and 962-DYV-D1\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\tSTE-FOY TOYOTA INC.\t\t4808\t18-8-73\tQ-44\tAccordée / Granted QL-65\t25-10-73\t1102-DY-D-l\t\t\t\t\t \t\tLOCATION DE MINIAUTO CHICOUTIMI\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4807\t18-8-73\tQ-56\tAccordée / Granted QPV-113-TF\t23-10-73\t56-A-D-l\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT REGIONAL DU SAGUENAY\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4805\t18-8-73\tQ-36\tAccordée / Granted QPV-114\t24-10-73\t160G-A-D-1\t\t\t\t\t \t\tAUTOBUS MESSIER (CHIBOUGAMAU)\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4S00\t18-8-73\tQ-12\tAccordée / Granted QPV-11S\t25-10-73\tQ-53-A-D-l AUTOBUS A.DROLET\t\t\t\t\t \t\tLIMITEE\t\t4919\t25-8-73\tR.Q.73\tAccordée / Granted QPV-116\t25-10 73\t3222-A-D-l\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tROGER DUPONT\t\t4929\t25-8-73\tQ.108\t QPV-117\t25-10-73\t3330-A-D-2 COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE QUEBEC Requérante / Applicant\t\t\t\t\t 6620 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t \t\tCORPORATION MUNI-\t\t\t\t\t \t\tCIPALE DE ST-\t\t\t\t\t \t\tDUNSTON DU LAC\t\t\t\t\t \t\tBEAUPORT\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tMise en cause\t\t4929\t25-8-73\tQ.107\t QPV-118\t25-10-73\t3330-A-D-l\t\t\t\t\t \t\tCOMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE QUEBEC Requérante / Applicant CORPORATION MUNICIPALE DES CANTONS UNIS DE STONEHAM ET DE TEWKESBURY\t\t\t\t\t \t\tMise en cause\t\t4929\t25-8-73\tQ-100\tAccordée / Granted QPE-2\t25-10-73\t24B3-A-D-1\t\t\t\t\t \t\tROGER DUCHESNEAU\t\t4922\t25-8-73\tQ-80\tAccordée / Granted QPE-3\t25-10-73\tQ-1888-A-D-1\t\t\t\t\t \t\tAUTOBITS TREMBLAY\t\t\t\t\t \t\tET PARADIS INC\t\t4920\t25-8-73\tQ-79\tAccordée / Granted QPE-4\t25-10-73\t3110-A-D-l\t\t\t\t\t \t\tRENE LETOl.'RNEAU\t\t\t\t\t \t\tENRG.\t\t4924\t25-8-73\tQ-85\tAccordée / Granted QPE-5\t25-10-73\t32-A-D-l\t\t\t\t\t \t\tLES AUTOBUS RIVE\t\t\t\t\t \t\tNORD LTEE\t\t4919\t25-8-73\tQ-72\tAccordée / Granted QCS-199\t25-10-73\t15957-V-D-8\t\t\t\t\t \t\tGERARD NOLIN LIMITEE Voiturier-roulier / Carrier GERMAIN LAJOIE Voiturier-remorqueur /\t\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t4806\t18-8-73\tQ-46\tAccordée / Granted QCS-200\t25-10-73\tQ-15957-V-D-1 GERARD NOLIN LIMITEE Voiturier-roulier / Carrier 23114-V\t\t\t\t\t \t\tAA.COULOMBE\t\t4805\t18-8-73\tQ-34\tAccordée / Granted QCS-201-TF\t25-10-73\t19150-V-D-l LES INDUSTRIES\t\t\t\t\t \t\tSAVARD INC.\t\t4791\t18-8-73\tQ-38\tAccordée / Granted PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis C'h ronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars QS-49 255-N-S-l\tTRANSPORT MARITIME VIGNEAULT LTEE\t1) jusqu'à déc.fin.de la Commission / (/) until final decision of the Commission.2) le ou vers le 15 décembre 1973 / On or about December tô, 1973.\tPermis spécial - Trspt de marchandises par navigation / Special permit - Trans, of goods by water.1) De Montréal à Blanc Sablon et retour - avec droit de desservir les ports intermédiaires entre eux - Pour le compte de Benoit Vigneault Ltée / From Montreal to Blanc-Sablon and return - with a right to operate between the intermediate ports - On behalf of Benoit Vigneault Ltée.2) De Sept-Iles à Baie Johan Beetz, pour le compte de LNGA Construction Ltée / From Sept-Iles to Baie Johan Beetz, on behalf of LNGA Construction Ltée. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973, 105' année, n° 1,5 6621 No du répertoire chronologique Chronological Repertory Xo.Nom du requérant Xame of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars QS-50 34-A-S-l QS-51 15957-V-S-5 QS-52 23443-V-S-l QS-53 15957-V-S-6 QS-54 23474-V-S-l 3-55 32-A-S-l QS-56 7041-V-S-l QS-57 23334-V-S-l QS-58 23479-V-S-l QS-59 5427-V-S-l MS-201 5427-V-S-l MS-200 23458-V-S-l MS-164 2656- V-S-1 PAUL TREMBLAY TRANSPORT LTEE GERARD NOLIN LIMITEE GERARD NADEAV GERARD NOLIN LIMITEE JULIEN BUJOLD AUTOBUS RIVE NORD LTEE TRANSPORT AMEDEE (\"AVER INC.WON GAVDREAULT LEONARD BANVILLE RIMOUSKI TRANSPORT LIMITEE RIMOUSKI TRANSPORT INC.M.DANIEL LEV ESQ UE URGEL CHARETTE TRANSPORT LTEE 3) entre le 15 octobre 1973 et le 15 novembre 1973 / Between October 15, 1973, and Xovember IS, 1973.6 mois jusqu'à dec.fin./ 6' months until final decision.G mois jusqu'à déc.fin./ 6\" months until final decision.6 mois jusqu'à déc.fin./ 0 months until final decision.6 mois jusqu'à déc.fin./ 6 months unlil final decision.jusqu'à la fin de la saison de hoekev 1973.74.Until the end of the 1973,74 hockey season.6 mois jusqu'à dec.fin.' G months until final decision.6 mois jusqu'à déc.fin.J 6 months until final decision.6 mois ou jusqu'à déc.fin.' 6' months or until final decision.6 mois ou déc.fin.(j months or final decision.3) De Montréal à Sept-Iles - Trspt.d'environ 20.000 sacs de pommes de terre - Pour le compte de Jos Girard & Fils Inc.I From Montreal to Sept-Iles - Trans, of about 20,000 bags of potatoes - On behalf of Jos Girard & Fils Inc.Demande de permis spécial.Modification relativement au parcours à suivre dans la Cité de Chicoutimi - Demande: rejetée ,' Request for a special permit.Modification in relation to the route to follow in the City of Chicoutimi - Request not granted.Demande de permis spécial - Courtier en transport avec Gérard Nadeau permis No 23443-V / Request for a special permit - Transport broker with Gérard Xadean; Permit Xo.23443-V.Demande de permis spécial - Transport par remorquage selon les clauses a à q inclusivement du permis No 15957-V de Gérard Nolin Ltée / Request for a special permit - Haulaway trans-portalion according to clauses a to q inclusive of permit Xo.15957-V of Gérard Xolin Ltée.Demande de permis spécial - Courtier en transport avec Julien Bujold No 23474-V / Request for a special permit - Transport broker with Julien Bujold Xo.23474-V.Demande de permis spécial - Transport par remorquage selon les clauses a à r; incl.du permis de Gérard Nolin Limitée.No 15957-V / Request for a special permît - Haulaway transportation according to clauses a to q inclusive of the permit of Géiaid Xolin Limitée, Xo.15957-V.Demande de permis spécial - Transport des joueurs du Club de hockey « Le Couillard de Ste-Foy ».Pour la saison 1973,74 f Request for a special permit - Transportation of the players of the Hockey Club \"Le Couillard de Ste.Foy\".For the 1973/74 season.Permis spécial - Transport de marchandise autorisé, par les clauses a à mm incl.de son permis No 7041-V / Special permit - Transportation of goods authorised by clauses c to mm inclusive of its permit Xo.704I-V.Permis spécial - Trspt par remorquage - Selon les clauses c à mm incl.du permis No 7041-V de Amédée Cayer Inc./ Special permit - Haulaway transportation - According to clauses c to mm inclusive of permit Xo.7041-V of Amédée Cayer Inc.Transport par remorquage selon les clauses c, d et / du permis No 5427-V f Haulaway transportation according to clauses c, d and f of permit Xo.Ô427-V.Permis spécial - Courtier en transport / Special permit - Transport broker.Désistement - Demande de courtier avec M.Daniel Levesque, No 23458-V.Accordée./ Withdrawal-Request for broker with M.Daniel Levesque, Xo.23458-V.Granted.Désistement - Demande de haulaway avec Rimouski Transport Inc.No 5427-V.Accordée./ Withdrawal - Request for haulaway transportation with Rimouski Transport Inc., Xo.5427-V.Granted.Permis spécial - Tirer remorques de C.P.Rail Montréal à tous les points qu'elle dessert en vertu des clauses d et k / Special permit - To haul the trailers of C.P, Rail, from Montreal to all points authorized by clauses d and k. 6622 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973.Vol.105.No.45 No du répertoire\t\tValidité: chronologique\tNom du requérant\tde:.à: Chronological\tName of Applicant\tValidity Repertory No.\t\tPeriod MS-156\tFORGET TRANSPORT INC.\t6 mois ou déc.365-V-S-l\t\tfin./ \t\tG months or final \t\tdecision.MS-179\tCOURTEMANCHE\t 19000-V-S-l\tTRANSPORT INC.\t MS-193\tM.GILLES MATHIEU\t6 mois ou déc.23460-V-S-l\t\tfin./ \t\tG months or final \t\tdécision.MS-192\tH.G.SNYDER TRICKING\t6 mois ou déc.1G057-V-S-5\tINC.\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-191\tM.JEAN-PIERRE OUELLET\t6 mois ou déc.23439-V\t\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-190\tH.G.SNYDER TRUCKING\t6 mois ou déc.16057-V-S-4\tINC.\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-185\tM.HENRI-PAUL CARIGAN\t6 mois ou déc.23204-V-S-l\t\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-184\tH.G.SNYDER TRUCKING\t6 mois ou déc.16057-V-S-3\tINC.\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-162\tFAFARD TRANSPORT INC.\t6 mois ou déc.23471-V\t\tfin./ \t\t6 months or final \t\tdecision.MS-163\tH.G.SNYDER TRUCKING\t6 mois ou déc.16057-V-S-2\tINC.\tfin.' \t\tG months or final \t\tdecision.MS-161\tPHILIPPE ROY TRANSPORT\t6 mois ou déc.14838-V-S-l\tINC.\tfin./ \t\tG months or final \t\tdecision.MS-187\tC.LEBOEUF TRANSPORT\t6 mois ou déc.703-V-S-l\tINC.\tfin.\t\tG months or final \t\tdecision.MS-186\tM.MICHELE MIGNOGNA\t 23435-V-S-l\t\t Détails du permis Particulars Permis spécial - De Marelan et Kilmar à Joliette, Tracy et Sorel - Trspt.produits réfractaires / Pour Canadian Refractories Ltd./ Spécial permit - From Marelan and Kilmar to Joliette, Tracy and Sorel - Trans, of refractory products -For Canadian Refractories Ltd.Permis spécial - Ajouter aux clauses d.e et f Bernière comme point d'origine - Refusé (art.33) / Special permit - Add to clauses d.e and f Bernière as the point of origin {art.33) - Not granted.Permis spécial - Haulaway pour H.G.Snyder Trucking Inc., No 16057-V / Special permit -Haulaway transportation for H.G.Snyder Trucking Inc.No.16057-V.Permis spécial - Courtieravec M.Gilles Mathieu.No 23460-V / Special permit - Broker with Mr.Gilles Mathieu.No.23460-V.Permis spécial - Haulaway avec H.G.Snyder Trucking Inc., No 16057-V / Special permit-Haulaway transportation with H.G.Snyder Trucking Inc.No.16057-V.Permis spécial - Courtier avec M.Jean-Pierre Ouellet.No 23439-V / Special permit - Broker with Mr.Jean-Pierre Ouellet.No.23439-V.Permis spécial - Haulaway avec H.G.Snyder Trucking Inc.No 16057-V / Special permit -Haulaway transportation with H.G.Snyder Trucking Inc., No.16057-V.Permis spécial - Courtier avec Henri-Paul Cari-gan.No 23204-V / Special permit - Broker with Henri-Paul Carigan.No.2S204-V.Permis spécial - Haulaway avec H.G.Snvder Trucking Inc.No 16057-V ,' Special permit -Haulaway transportation with H.G.Snyder Trucking Inc.No.16057-V.Permis special - Courtier avec Fafard Transport Inc.No 23471 -V /Special permit - Broker with Fafard Transport Inc., No.2S471-V.Permis spécial - De St-Gérard, Cté Wolfe, à tous les endroits dans un rayon de 500 milles et retour - Transport pierres usinées et emballées - Pour Granite St-Gérard Inc./ Special permit - From St.Gérard, County of Wolfe to all points with a radius of 500 miles and return -Transportation of bright and packed stones -For Granite St.Gérard Inc.Permis spécial - Louer, à long terme, un tracteur de marque Chrysler CN 900.1973 de la compagnie \u2022 Centre de Camions Chrysler Montréal Ltée / Special permit - To lease a tractor on a long-term basis 1.1973 Chrysler CN 900) from \"Centre de Camions Chrysler Montréal Ltée\".Permis spécial - Montréal 5 milles - Trspt.raisins a vin - Pour Crelinsten Fruit Co.Refusé (art.33) / Special permit - Montreal 5 miles - Trans, of wine grapes / For Crelinsten Fruit Co.Not granted (art.33). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1978, 105' année, n° 45 6623 AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\tDate\tRequérants\t\t\t\tCause\t \t\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCote\t MCR-392\t29-10-73\t22944-V\t\t\t\t\t MCR-393\t29-10-73\tCAMILLE TRUDEAU\t3-15-26\t2246\t14-04-73\t3890\tRejetée / Rejected \t\t5431-V DAVELUY VILLE\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT ENR.\t1-1-50\t2537\t28-04-73\t4226\tAccordée en partie / \t\t\t\t\t\t\tPartly granted MCR-394\t29-10-73\t17492-V\t\t\t\t\t \t\tHILAIRE CHARRON\t1-1-122\t2564\t28-04-73\t4206\tRejetée / Rejected MCR-395\t29-10-73\t18483-V COMPTOIR DES CULTIVATEURS\t\t\t\t\t \t\tENRG.\t1-1-37\t2530\t28-04-73\t4227\tAccordé en partie / \t\t\t\t\t\t\tPartly granted MCR-396\t29-10-73\t13889-V JEAN-PAUT.TRUDEAU\t\t\t\t\t \t\tET FILS LIMITEE\t1-1-68\t2543\t28-04-73\t4204\tRejetée / Rejected MCR-397\t29-10-73\t4196-V\t\t\t\t\t \t\tLAGUE EXPRESS INC.\t1-1-120\t2563\t28-04-73\t4148\tAccordée / Granted MCR-400\t29-10-73\t22673-V HUME EQUIPMENT\t\t\t\t\t \t\tCOMPANY\t1-1-119\t2562\t28-04-73\t4176\tRejetée / Rejected MCR-401\t26-10-73\t23157-V\t\t\t\t\t \t\tALBERT D.HAMAOUI\t1-1-79\t2548\t28-04-73\t4202\tRejetée / Rejected MCR-402\t29-10-73\t22965-V\t\t\t\t\t \t\tRAYMOND DUVAL\t3-16-62\t2250\t14-04-73\t3928\tRejetée / Rejected MCR-403\t29-10-73\t20542-V\t\t\t\t\t \t\tALPHONSE RANGER\t3-16-54\t2250\t14-04-73\t3936\tRejetée / Rejected MCR-J04\t29-10-73\t23194-V\t\t\t\t\t \t\tLAMBERT & WILLIAM\t1-3-6\t2394\t21-04-73\t4231\tDésistement / \t\tSNIPPE\t\t\t\t\tWithdrawal -MCR-407\t30-10-73\t23145-V\t\t\t\t\t \t\tRENE LEHOUX\t1-1-80\t2549\t28-04-73\t4172\tAccordée / Granted MCR-409\t30-10-73\t23165-V\t\t\t\t\t MCR-414\t\tYVON CORMIER\t1-1-98\t2554\t28-04-73\t4169\tRejetée / Rejected \t26-10-73\t22473-V\t\t\t\t\t MCS-35\t\tEDMOND SWEENEY\t1-1-117\t2561\t28-04-73\t4196\tRejetée / Rejected \t26-10-73\t10794-V\t\t\t\t\t \t\tG.COURCHESNE\t1-1-31\t2528\t28-04-73\t4147\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT INC.\t\t\t\t\t QCS-202\t29-10-73\t2278-V\t\t\t\t\t \t\tHAMEL TRANSPORT\t1-19-72\t4424\t28-07-73\t2448\tAccordée / Granted \t\tLTEE\t\t\t\t\t QC8-204\t30-10-73\tQ-21087-V\t\t\t\t\t \t\tS.A.F.CONSTRUCTION\t1-6-74\t2725\t05-05-73\tR.Q.,\tAccordée / Granted \t\tINC.\t\t\t\t2353\t QCS-205\t30-10-73\t23291-V\t\t\t\t\t \t\tREAL BLANCHETTE\t1-18-2\t4285\t21-07-73\t2456\tAccordée / Granted SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS 26-10-73 26-10-73 5341-TFM 5342-TFM SOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE Demandes de modifications de tarifs Applications for modifications of tariffs 5943-TFM SOUTHERN MOTOR CARRIERS Demande de modification de tarifs Application for modification of tariffs 4790 4792 5087 18-08-73 18-08-73 01-09-73 M-32 M-48 M-145 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 6624 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 No MCR-391-TF MCR-398 MCR-399-TF MCR-105-TF MCR-406 MCR-408 MCR-410-TF MCR-411-TF MCR-412-TF MCR-413-TF 26-10-73 29-10-73 26-10-73 30-10-73 30-10-73 30-10-73 31-10-73 31-10-73 31-10-73 31-10-73 Requérants Applicants 2696-V 5129-TFM GEVRY TRANSPORT INC.Demandes de modification de tarifs Applications for modifications of tariffs 17753-V FOX & GINN INC.BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.5163-64-TFM 5252-53-TFM.5348-TFM.5367-TFM.5417-TFM.5449-50-TFM.5451-TFM.5S48-TF.M, 5S75-76-TFM.5577-78-TFM, 5596-97-TFM, S599-TF.M, Demandes de modifications de tarifs Applications for modifications of tariffs 1782-V HILDEGE LAPORTE TRANSPORT ENRG.Demande de modification de tarifs Application for modification of tariffs 20380-V BRISSETTE TRANSPORT LTEE 6379-V HENRI-GEORGES FOURNIER (décédé / deceased) PAULINE PICARD FOURNIER (Mme / .Mrs) 1930-V PROVOST CARTAGE INC.Demande de modification de tarifs Application for modification of tariffs 5700-TFM PROVOST CARTAGE INC.Demande de modification de tarifs Application for modification of tariffs 20905-V DAILY FREIGHT FORWARDERS LTD.Demande de modification de tarifs A pplication for modification of tariffs CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N Demandes pour modification des tarifs / Applira-cations for modification of tariffs 5166-TFM.Bulletin 1-20-9 5276 4517 4788 5277 4711 4722 5278 4795 5277 4790/ 89 4792 4795 08-09-73 04-08-73 18-08-73 08-09-73 11-08-73 11-08-72 08-09-73 08-09-73 08-09-73 18-08-73 M-156 M-ll M-164 M-166 M-65 M-160 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granferf Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6625 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tBulletin\tpage\tdate\tCase\tDécisions \t\t5351/52-TFM.5551/52-TFM.5553/54-TFM.5555/56-TFM, 5701/02-TFM.\t\t\t\t\t MCR-415-\t01-11-73\t\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t4913\t25-08-73\tM-112\tAccordée / Granted \t\tDU QUEBEC INC.\t\t\t\t\t MCR-416-\t01-11-73\t\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t4912\t25-08-73\tM-103\tAccordée / Granted \t\tDU QUEBEC INC.708-DY D-l\t\t\t\t\t QL-66\t29-10-73\t\t\t\t\t\t \t\tLOCATION PINARD\t\t5474\t22-10-73\tQ-153\tAccordée / Granted \t\tINC.\t\t\t\t\t QL-67\t29-10-73\t1053-DY\t\t\t\t\t \t\tM.NORBERT KENNEDY\t1-12-60\t3618\t16-06-73\t\tAccordée / Granted QL-68\t29-10-73\t609-DY\t\t\t\t\t \t\tAUTO A LOUER\t1-16-46\t4131\t14-07-73\t\tAccordée / Granted \t\t(RIMOUSKI) INC.\t\t\t\t\t QL-69\t31-10-73\t713-DY\t\t\t\t\t \t\tDIONNE AUTOMOBILE INC.948-DYV\t\t\t\t\t \t\tDIONNE AUTO INC.\t\t4706\t11-08-73\t\tLa Commission revise sa \t\tAvis de la Commission\t\t\t\t\tdécision du 24/05/73 \t\tProprio Motu Notice \"Proprio Motu\" by\t\t\t\t\tpour disposer des dé- \t\t\t\t\t\t\tpôts / The Commission \t\tthe Commission\t\t\t\t\trevises its decision of 24/05/7S in order to dispose of the deposits.MCS-34\t29-10-73\t23002-V LEVIS CARTAGE MOVING & PARCEL DELI-\t\t\t\t\t \t\tVRY\t\t1500\t10-03-73\tM-3980\tAccordée / Granted MCS-35\t31-10-73\t15911-V QUEENSWAY TANK\t\t\t\t\t \t\tLINE LIMITED\t3-08-39\t1780\t24-03-73\t\tAccordée / Granted MCS-36-TF\t01-11-73\t1451-V\t\t\t\t\t \t\tMELDRUM THE\t\t\t\t\t \t\tMOVER LTD.\t\t4912\t25-08-73\tM-106\tAccordée / Granted QSF-6-TF\t29-10-73\t3-CFD-l\t\t\t\t\t \t\tLE CHEMIN DE FER DE MATANE ET DU\t\t\t\t\t \t\tGOLFE\t\t4805\t18-08-73\tQ-35\tAccordée / Granted QCS-203\t30-10-73\t1341-V\t\t\t\t\t \t\tMONTCALM EXPRESS INC.Requérant-vendeur Applicant-vendor 23227-V LES DEMENAGEMENT\t\t\t\t\t \t\tTRANS-QUEBEC INC.\t\t\t\tQ-895-C\tAccordée / Granted \t\tRequéran t-acquéreur\t1-1/57\t3365\t02-06-73\t\t \t\tA pplicant-purchaser\t\t\t\t\t QCS-206\t31-10-73\t15178-V-D-l BOURGAULT TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT LTEE\t\t4806\t18-08-73\tQ-52\tAccordée / Granted ML-141\t30-10-73\t9098-V LAPOINTE TRANSPORT LIMITEE\t\t4710\t11-08-73\t\tAccordée / Granted QCR-303\t31-10-73\t8903-V ADONAILEMIRE Requérant-vendeur Applicant-vendor 12940-V BEAULIEU TRANSPORT LIMITEE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser\t\t\t\t\t 6626 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10.1973, Vol.105, No.45 No Date tJCR 304 31-10-73 QCH 306 31-10-73 QCR-306 31-10-73 QCR-307 31-10-73 (JCR nos 31-10-73 QCR-309 31-10 73 Requérants Applicants Avis de la Commission « Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 32 V TRANSPORT DALLAIRE LTEE Avis de la Commission \" Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 13337-V MESSAGERIE VILLENEUVE INC.Avis de la Commission « Proprio motu \u2022 Notice \"Proprio Motu\" by the Commission 15741-V SAVARIA TRANSPORT LIMITEE Avis de la Commission ¦ Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 11437-V-P-l LTSLET EXPRESS INC.Avis de la Commission ¦ Proprio motu » 5603-29-9-73 Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 18792-V-P-1 MARC AURELE DUPONT Avis de la Commission ¦ Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 23029- V-P-l M.EUGENE LAVOIE Avis de la Commission \u2022 Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission Bulletin G.O.Q.page 4706 4706 4706 4706 5603 5603 5603 date 11-08-73 11-08-73 I I .is 73 11-08-73 29-09-73 Cause Case (J-2295 M-3589 29-09-73 29-09-73 Décisions La Commission revise sa décision du 31/1.73 pour disposer des dépôts / The Commission revises its decision of 31/1/73 in order to dispose of the deposits La Commission revise sa décision du 13/4/73 pour disposer des dépôts / The Commission rerises its decision of 13/4/73 in order to dispose of the deposits La Commission revise sa décision du 31/5/73 pour disposer des dépôts/ The Commission revises its decision of SI /S/73 in order to dispose of the deposits La Commission revise sa décision du 30/1/73 pour disposer des dépôts / The Commission revises its decision of 30/1/73 in order to dispose of the deposits La Commission décrète l'annulation du permis spécial émis à L'Islet Express Inc.en date du 21/6/73 The Commission orders the cancellation of the special permit issued to L'll'et Express Inc.dated 21/ 6/73 La Commission annule le permis 18792-V émis à M.Marc-Au-rèle Dupont / The Commission cancels permit 18792- V issued to Mr Marc-A urèle Dupont La Commission revise sa décision du 3 août 1973 pour disposer du dépôt de cautionnement du requérant / The Commission revises its decision of August 3.1973.in order to dispose of the applicant's deposit GAZETTE OFFICIELLE DC QUEBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 Ko Date QCR-310 31-10-73 QCR-311 31-10-73 QCR-312 QCR-313 QPV-120 1- 11-73 1-11-73 31-10-73 QPV-121 31-10-73 QPV-122 QPV-123 QPV-124-TF QPV-126 31-10-73 1-11-73 1-11-73 1-11-73 Requérants Applicants 22685-V-P-l ARRIMAGE ET SERVICE CARTIER INC.CARTIER STEVEDORING AND SERVICES INC.Avis de la Commission » Proprio motu » Xotice \"Propria Motu\" by the Commission 23226-V-P-l PAUL-AIME CASTON- GUAY Avis de la Commission « Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission Q-22340-V SUNBURY TRANSPORT LIMITED 22704-V-D-2 COURRIER TRANS-QUEBEC INC.2977-A-A-T TAXI ST-LOUIS LTEE Avis de la Commission \u2022 Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 3013-A AMEDEE PLANTE Avis de la Commission « Proprio motu « Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission 2808-A GERALD DOUCET Avis de la Commission « Proprio motu » Xotice \"Proprio Motu\" by the Commission Q-1722-A-D-1 DENIS HUARD 3004-A-D-2 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AUTOBUS DU QUE-BEC 1794-A-T-D-l TAXI TREMBLAY ENRG.Bulletin 1-06-72 G.O.Q.page date 5602 5602 2723 4929 4706 4706 4706 1920 4792 5279 29-09-73 29-09-73 05-05-73 25-08-73 11-08-73 11-08-73 11-08-73 25-08-73 18-08-73 08-09-73 Cause Case Q-105 Q-78 Q-49 Q-131 Décisions La Commission corrige la décision du 3 août 1973 relativement au dépôt du requérant / The Commission corrects the decision of August S, I97S respecting the applicant's deposit.La Commission corrige sa décision du 3/8/73 pour disposer des dépôts / The Commission corrects its decision of 318173 in order to dispose of the deposits.Accordée / Granted Accordée / Granted La Commission revise sa décision du 14/2/73 pour disposer des dépôts / The Commission revises its decision of 14/2/73 in order to dispose of the deposits.La Commission revise sa décision 14/2/73 pour disposer des dépôts / The Commission revises its decision of 14/2/73 in order to dispose of the deposits.La Commission revise sa décision 7/12/73 The Commission revises its decision of 7/12/73 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Sorembtr 10.197.1.Vol.10».No.j-5 PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-60 3255-A-D-l STF QS-61 2770-A-S-l QS-62 478-V-S-2 QS-63 1606-A-S-l QS-64 23482-V-S-l QS-65 1274-DV 1056-DYV S-l Nom du requérant Name of Applicant AUTOCAR FOURNIER INC.LEON CLOUTIEI1 FRANÇOIS NOLIN LIMITEE AUTOBUS MESSIER CHIBOUGAMAU INC.JEAN-LOUIS LACOURSIEKE SHEFFORD CHRYSLER PLYMOUTH LTEE 6 mois à compter ou jusqu'à déc.fin.6 months from or until final decision.Durant la saison de hookey 1973/74 During the 1973/74 hockey season.G mois à compter du 26/10/73 6\" months from 26/10/73 mois à compter du 26/10/73 0 months from 26/10/73 Détails du permis Particulars Permis spécial - Changement & l'horaire actuel daté du 18 juin 1972 / Special permit - Modification of the present lime-table dated June 18.1972.Permis spécial - Trspt.des joueurs et supporteurs du club de hockey de St-Frédéric et Tring Jonction a l'aréna de Ste-Marie-de-Beauce / Special permit - Transp.of hockey players and fans of the Si.Frédéric and Tring Jonction hockey clubs to the Ste.Marie-de-Beauce arena.Demande d'autorisation - Trspt.de 1.500,000 lbs.de rebuts d'aluminium de Godbout Saguenay à St-Jérôme (Terrebonne) pour Liberty Smelting Works (1967) Ltd.Rejetée / Application for authorization - Trans, of 1,600,000 lbs.of aluminum scrap from Godbout Saguenay to St.Jérôme (Terrebonne) on behalf of Liberty Smelting Works (1967) Ltd.Rejected.Demande de permis spécial - Trspt.spécial par autobus, de résidents et d'écoliers de la ville de Chibougamau à la Mine Chibex.Rejetée / Application for spécial permit - Special trans., by bus.of residents and school children from the Town of Chibougamau to the Chibez Mine.Rejected.Permis spécial - Grand'Mère et endroits ne dépassant pas 5 milles - Livraison de mets préparés -Pour le compte du Restaurant Bravo Pizzeria / Special permit - Grand'Mcre and localities no further than S miles - Delivery of prepared foods -On behalf of Restaurant Bravo Pizzeria.Permis spécial - 1) a) Location à court terme de véhicules de promenade aux clients dont les véhicules sont en réparation.1) 6) Location de véhicules de promenade (campeur motorisé).2) Location à long terme (un an ou plus) de véhicules de promenade (automobiles et Stations-Wagons) .3) o) Location à court terme de véhicules de commerce et de livraison aux clients dont les véhicules sont en réparation.3) 6) Location à court terme de roulottes de voyage.4) Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, Tracteurs, remorques) à long terme (un an et plus) à 947 rue Principale Gran- Special permit - (1) (a) Leasing on a short-term basis of pleasure vehicles to customers whose own vehicles are under repair.(1) (b) Leasing of pleasure vehicles (motorized campers).(2) Leasing on a long-term basis (one year or more) of pleasure vehicles (automobiles and stations-wagons).(3) (a) Leasing on a short-term basis of commercial and delivery vehicles to customers whose own vehicles are under repair. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6629 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars QS-66 1273-DV et 1055-DYV S-l MOUSSETTE CHRYSLER PLYMOUTH INC.QS-67 3417-A-S-l QS-68 56-A-D-l MTF QS-69 7181-V-S-2 QS-70 23492-V-S-l ROLAND LORD TRANSPORT REGIONAL DU SAG U EN A Y INC.LA POINTE & FILS LTEE ROY & PLANTE LIMITEE 6 mois à compter du 26/10/73 6\" months from 26/10/73 6 mois à compter du 22/10/73 ou jusqu'à déc.fin.6 months from 22/10/73 or until final decision 6 mois ou jusqu'à déc.fin.6' months or until final decision (3) (b) Leasing of travel trailers on a short-term basis.4) Leasing on a long term basis (one year or more) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) at 947 Principale Street, Granby, P.Q.Permis spécial / 1) Location à long terme (un an et plus) de véhicules de promenade (automobile et Station-Wagons) .2) Location à court terme de véhicules de promenade aux clients dont les véhicules sont en réparation.3) Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions tracteurs, remorques).4) Location à court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) aux clients dont les véhicules sont en réparation à 1400 boul.Curé Labelle, Cho-medy, Laval.Special permît / (1) Leasing on a long-term basis (one year or more) of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons).(2) Leasing on a short-term basis of pleasure vehicles to customers whose own vehicles are under repair.(3) Leasing on a long-term basis (one year or more) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers).(4) Leasing on a short-term basis of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) to customers whose own vehicles arc under repair, at I4OO Cure Labelle Boulevard, Chomedy, Laval.Demande de permis spécial / Trspt.d'étudiants et chefs de groupe du CEGEP La Pocatière à Cap-Rouge, Ste-Foy, P.Q.durant l'année scolaire 1973/74.Rejetée / Application for a special permit / Trans, of students and group leaders from La Pocatière CEGEP to Cap-Rouge, Ste.Foy during the 1973/74 school year.Rejected.Permis spécial / Pour modification de tarifs / Special permit / For modification of tariffs.Demande de permis spécial / les services de transport détenus antérieurement par Lyster Transport Enr.selon les clauses c, e, g, h et j du permis No 7479-V de ce dernier.Rejetée / Application for a special permit / the transport services formerly held by Lyster Transport Enr., according to c, e, g, h and j of permit No.7479-V of the latter.Rejected.Permis spécial / De Thetford-Mines à Montréal et retour/Pour le transport inter-bureaux de Asbestos Corporation Limited / Pour le compte de Asbestos Corporation Ltd./ Special permit / From Thetford Mines to Montreal and return I For the transportation between the offices of Asbestos Corporation Limited./ On behalf of Asbestos Corporation Ltd. 6630 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.k5 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant QS-71 G.DION TRANSPORT INC.13805-V-S-l QS-72 23056-V-S-l WON CHABOT MS-219 DESROSIERS LOCATION INC.845-DV S-l MS-237 7737-V-S-l MS-238 16202-V-S-l MS-240 23481-V-S-l MS-241 186-V-S MS 242 15140-V-S-l MS-245 15911-V-S-l MS-244 22092-V-S-I BELLECHASSE TRANSPORT INC.HUME'S TRANSPORT LTD.FERME V.MELOCHE ENRG.HOÏ/LE EXPRESS LTEE DELSON TRANSPORT LIMITEE QUEENS WAY TANK LINES LTD.LAMBERT M.GILLES 6 mois à compter du 31/10/73 6 months from 31110173 6 molt & compter du 31/10/73 6 months from 31/10/7$ Détails du permis Part ici* far* 6 mois à compter du 15/10)73 ou déc.fin / 6' months from 15/10/73 or final decision.A court terme / On a short-term basts 6 mois ou déc.fin / 6\" months or final deci-s ion 6 moi> ou déc.fin / 0 months or final decision 6 mois ou déc.fin /6 months or final decision 6 mois ou déc.fin 10 months or final decision 6 mois ou déc.fin / 6 months or final decision f» mois ou déc.fin / 0 months or final decision Permis spécial / De tout endroit à tout autre endroit situé dans un rayon de 40 milles de Victoriavïlle.pour le remorquage de maisons mobiles pour le compte de la Commission scolaire régionale des Bois-Francs./ Special permit / From any point to any other point located within a radius of 40 miles from Victoriaville, for the haulage of mobile homes on behalf of Bois-Francs Regional School Board.Permis special / Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de la dite ville.De Québec aux endroits suivants: Beaupré, Charny, Donnacona, St-Marc-des-Carrières.Ville St-Raymond.comté de Portneuf.Pour le transport de gazoline par remorque-citerne, pour le compte de Produits Pétroliers Champlain Liée./ Special permit / Québec and ail points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City.From Québec to the following points: Beaupré, Charny, Donnacona.St.Marc-des-Carrières, Town of St.Raymond, County of Portneuf./ For the transportation of gasoline by tank trailer, on behalf of Produits Pétroliers Champlain Ltée.Location à court terme de véhicules de promenade, aux clients de Desrosiers Automobile Ltée et Lefebvre Automobile Ltée / Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis to the customers of Desrosiers Automobile Ltée and Lefebvre A utomobile Ltée.Automation - Location de deux véhicules de Five Wheels Leasing Montréal / Authorization -Leasing of two vehicles from Five Wheels Leasing Montreal.Permis spécial - Des frontières Québec-Ontario h Montréal et Québec - trspt.crème glacée -pour Orange Roof of Canada Ltd./ Special permit-From the Québec-Ontario borders to Montreal and Québec \u2014 Trans, of ice cream -For Orange Roof of Canada Ltd.Permit special - De Dollard-des-Ormeaux et de toute municipalité située dans la prov.de Que.à tout point de la prov.de Que.- Trspt.de chevaux / Special permit - From Dollard-des-Ormeaux and any municipality located in the Province of Québec to any point in the Province of Québec - Trans, of horses.Permis spécial - Remorquage des remorques de Delson Transport Limitée selon les clauses a à z de Delson / Special permit - Haulaway transportation of the trailers of Delson Transport Limited according to Delson's clauses a to z.Permis spécial - Courtier pour le transport de marchandises - Selon les clauses a à z - Utilisant le service de remorquage de Houle Express Ltée / Special permit - Transport broker for the transportatioTi of goods - According to clauses a to t, - Utilizing the haulaway service of Houle Express Ltée.Permis spécial - Trspt.* Carbon pellets » - Des frontières Québec-Ontario à Valleyfield et retour./ Special permit - Trans, of \"carbon pellets\" - From the Québec-Ontario borders to Valleyfield and return.Permis spécial - Haulaway avec Brazeau Transport Inc.No 6793-V / Special permit - Haulaway transportation with Brazeau Transport Inc.Xo.b-793-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6631 No du répertoire chronologique Ch ro no logical Repertory No.MS-243 6793-V-S-7 MS-172 23193-V-S-l 7486-V-S-l MS-217 22508-V-S-l MS-211 87-V-S-2 MS-210 23464-V-S-l MS-212 23463-Y-S-l MS-213 23478-V-S-l MS-214 21752-V-S-2 MS-215 21752-V-S-l MS-209 21992-V-S-2 Nom du requérant Name of Applicant BRAZEAU TRANSPORT INC.TRANSPORT PHOENIX INC.J.J.CARTAGE & CITY DELIVERY REG'D AFFILIATED WASTE DISPOSAL INC.FINCH & SONS TRANSPORT LTD.TURNER.M.ROGER JACK B.KELLY INC.GAS INCORPORATED DELIVRO (CANADA) INC.DELIVRO (CANADA) INC.ARNOLD BROS TRANSPORT LTD.Validité: de:.à Validity Period 6 mois ou déc.fin 16 months or final decision 6 mois ou déc.fin 16 months or final decision G mois ou déc.fin / 6 months or final decision Un mois / One month 6 mois ou déc.fin 16 months or final decision 6 mois ou déc.fin / 6* months or final decision G mois / 6 month.G mois ou dec.fin / G months or final decision G mois ou déc.fin / 6 months or final decision 6 mois ou déc.fin / 6 months or final decision 90 jours à compter du 15/10/73/50 days from ISIWJS Détails du permis Particulars Permis spécial - Courtier avec M.Gilles Lambert.No 22092-V / Special permit - Transport broker with Mr.Gilles Lambert.No.22092-V.Permis spécial - Prolongation du permis spécial émis le 26 mars 1973 - Montréal 5 milles et de Montréal à toutes les localités situées dans la province de Québec et retour - Trspt.acier brut et fini et outillage - Pour Produits d'Acier Phoenix Ltée / Special permit - Extension of the special permit issued on March 26, 1973-Montreal 5 miles and from Montreal to all points located in the Province of Québec and return \u2014 Trans, of raw and finished steel and tools - For Produits d'Acier Phoenix Ltée.Permis spécial - De Montréal à Ste-Thérèse et retour - Trspt.équipement électronique - Pour Symphonie Electronic Corp./ Special permit-From Montreal to Ste.Thérèse and return -Trans, of electronic equipment - For Symphonic Electronic Corp.Autorisation - Location de un tracteur Auto Car 58-FX-5420 / Aidhorization - Leasing of one Auto Car 58-FX-5420 Tractor.Permis spécial - Courtier avec M.Roger Turner No 23464-V / Special permit - Transport broker with Mr.Roger Turner No.23464-V.Permis spécial - Haulaway avec Finch & Sons Transport Ltd.No 87-V / Special permit - Haulaway transportation with Finch & Sons Transport Ltd.No.S7~V Permis spécial - Des frontières Québec-Ontario à Montréal - Trspt.d'oxygène et d'azote liquéfiés - Pour Canadian Liquid Air Ltd./ Special permit - From the Québec-Ontario borders to Montreal - Trans, of Iv/ucfied oxygen and nitrogen - For Canadian Liquid Air Ltd.Permis spécial - Trspt.gaz naturel liquéfié - Des frontières Québec-Etats-Unis à Montréal et retour - Pour Lowell Gas Company et Bracton Taunton Gas Co./ Special permit - Trans of liquefied natural gas - From the Quebec-United States borders to Montreal and return - For àLowell Gas Company and Bracton Taunton Gas Co.Permis spécial - De Montréal à la frontière Québec-Ontario - Trspt.colis n'excédant pas 50 livres (Destination ou origine: Toronto) clause e I Special permit - From Montreal to the Québec-Ontario border - Trans, of parcels not weighing more than 50 pounds (Destination or origin: Toronto) clause e.Permis spécial - De Sherbrooke :\\ Montréal et retour - Trspt.colis de 50 livres ou moins -clause d / Special permit - From Sherbrooke to Montreal and return - Trans, of parcels weighing 60 pounds of less - Clause d.Permis spécial - De la frontière Québec-Ontario à tous les points de la prov.de Québec Trspt.d'épandeurs à fumier - Pour Massey-Ferguson Industries Ltd./ Special permit - From the Québec-Ontario border to all points in the Province of Québec - Trans, of muck spreaders - For Massey Ferguson Industries Ltd. 6632 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-236 1550-V-S-l MS-227 23484-V-S-l MS-222 2103-V-S-l MS-216 23483-V-S-l MS-218 1092-V-S-l MS-207 7306-V-S-l Nom du requérant Name of Applicant MS-20S 1407-V-S-l H.LA PALME TRANSPORT LTEE JACQUES RICHER INC.RACETTE, M.KERNAND CASKET DISTRIBUTORS INC.VIC'S CARTAGE SERVICE INC.TRANSPORT GAUTHIER ENRG.Validité: de:.à Validity Period 6 mois ou déc.fin 16 months or final deci-sion MONTREAL CARTAGE SYSTEM LTD.6 mois ou déc.fin 16 months or final decision 6 mois ou déc.fin / 6 months or final decision 6 mois ou déc.fin 16 months or final decision Détails du permis Particulars Permis spécial - De Montréal à tous les endroits situés dans la prov.de Québec - Trspt.farine en sacs - Pour Farine Phénix Ltée / Special permit - From Montreal to all points located in the Province of Québec - Trans, of flour in bags -For Farine Phénix Ltée.Permis spécial - Montréal 5 et 75 milles - Trspt.blocs de ciment et de brique - Pour Cie Miron Ltée.Refusé (art.33) / Special permit - Montreal S and 76 miles - Trans, of concrete and brick blocks - For Cie Miron Liée.Rejected (art.S3).Permis spécial - Service des fermes situées dans un rayon de 5 milles de St-Lin à St-Sulpice et St.Janvier et retour - Trspt.légumes en bottes -Pour le public en général / Special permit -Service from the farm* locnted irùhin a radius of ft miles from St.Lin to St.Sulpice and St.Janvier and return - Trans, of canned vegetables - For the general public.Permis spécial - De Lancaster (Kentucky) à Montréal - Trspt.de cercueils - Pour National Casket Co.Inc./ Special permit - From Lancaster (Kentucky) to Montreal - Trans, of coffins - For National Casket Co.Inc.Autorisation - Location de camions de Hertz Truck Rental - Refusé (art.13 FF de l'Ordonnance générale sur le camionnage)./ Authorization - Leasing of trucks from Hertz Truck Rental - Rejected (art.IS FF of General Order on Trucking).Permis spécial - De Delson à tous les endroits dans la Province dans un rayon de 500 milles -Trspt.poteaux créosotes - Pour Domtar Chemicals Ltd.Excl.- Refusé (art.44.6 de l'Ordonnance _ générale sur le camionnage)./Special permit - From Delson to all points in the Province within a radius of 600 miles - Trans, of creosoted posts - For Domtar Chemicals Ltd.Excl.- Rejected (art.44.6 of General Order on Trucking).Permis spécial - De Montréal rayon de 30 milles et retour / Special permit - From Montreal radius of 30 miles ana return.Le directeur du service des compagnies, 54434-0 Pierre Desjardins.\t54434-0\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.Places d'affaires dans la Province\tPlaces\tof Business in the Province LEO FOURNIER TRANSPORT INC.Avis est donné que l'adresse dans la province de Québec de la compagnie « LEO FOURNIER TRANSPORT INC.», détentrice du permis No 19641-V est la suivante: 1 rue Salderbury, Vallevfield, Québec-373-3230.Le procureur de la compagnie, 54546 Daniel J.Lynch.LEO FOURNIER TRANSPORT INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"LEO FOURNIER TRANSPORT INC.\", permit No.19641-V is 1 Salderbury Street, Vallevfield, Québec - 373-3230.54Ô46-0 Daniel J.Lynch, Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 f.633 HENDRIE & COMPANY LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « HENDRIE & COMPANY LIMITED » permis No 16152-V est: 212, rue Bloom-ficld Outremont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 51547-0 Perreault & Rivet.HENDRIE & COMPANY LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"HENDRIE & COMPANY LIMITED\", permit No: 16152-V is 212 Bloomfield St.Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet.54547-0 Attorneys for the Company.AUGUSTE LUSSIER (LUSSIER TRANSPORT ENRG) Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « AUGUSTE LUSSIER (LUSSIER TRANSPORT ENRG.) » permis No: 21162-Y est: 275.Guy.Longueuil.(Québec) J4G 1.18.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 54548-0 Pekkeallt & Rivet.AUGUSTE LUSSIER (LUSSIER TRANSPORT ENRG) Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"AUGUSTE LUSSIER (LUSSIER TRANSPORT ENRG.)\", permit No.: 21162-V is 275 Guy St.Longueuil (Québec), J4G 1J8.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54548-0 Attorneys fur the Cum puny.RELIABLE TRANSPORT LIMITED Avis est donné que la compagnie « RELIABLE TRANSPORT LIMITED », permis numéro 3955-Y.a établi son bureau dans la province de Québec au numéro 10325, avenue Ryan, Dorval, Québec, téléphone: 636-0270.Le rice-prisident, 54549 G.Kreaden.RELIABLE TRANSPORT LIMITED Notice is given that \"RELIABLE TRANSPORT LIMITED\", permit No 3955-V.designated its place of business in the Province of Québec at 10325 Ryan Avenue, Dorval, Quebec, telephone No 636-0270.G.Kreadex, 54549-0 Vice-President.C.I.WHITTEN TRANSFER CO.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « C.I.WHITTEN TRANSFER CO.» permis No: 22091-Y est: 435, rue Norman, Ville St-Pierre, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54550-o Perreault & Rivet, CI.WHITTEN TRANSFER CO.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"C.I.WHITTEN TRANSFER CO.\".permit No.: 22091-V is 435 Norman St.Ville St.Picrre.Province of Quebec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54550-o Attorneys for the Company.B.S.TRUCKING REG'D Avis est donné que l'adresse, pour la province de Quebec, de la compagnie « B.S.TRUCKING REG'D », permis No: 23196-V est: 5101 boulevard Industriel, Montréal-Nord.Téléphone: 324-7182-3.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54558-0 Perreault & Rivet.B.S.TRUCKING REG'D Notice is given that the adress.for the Province of Québec, of \"B.S.TRUCKING REG'D\", permit No.: 23196-V is 5101 Industrial Boulevard, Montreal-North.Telephone: 324-7182-3.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54558-0 A ttorneys for the company.ROGER CLAVETTE Conformément aux dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi des transports, Roger Clavette donne avis qu'il désigne le lieu suivant comme sa place d'affaires: 373 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup, P.Q.I* procureur de Roger Clarelle, 54559-o Me Jacques Lanclois.ROGER CLAVETTE According to the dispositions of the regulations adopted under the Transport Act, Roger Clavette hereby gives notice that he has designated the following place as his place of business to wit: 373 Témiscouata Street, Rivière-du-Loup, P.Q.Me Jacques Lakclois, 54559-0 Attorney for Roger Clarette. 6034 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1973.Vol.JOB.No.45 AURELE DUREPOS Conformément aux dispositions des règlements adoptés en vertu de la Ixii des transports, Aurèle Durepos donne par les présentes avis qu'il désigne le lieu suivant comme place d'affaires: 373 rue Témiscouata.Ri-vièrc-du-l,oup, P.Q.Le procureur de Aurèle Durepos, 54560-o Me Jacques Langlois.AURELE DUREPOS According to the dispositions of the regulations adopted under the Transport Act, Aurèle Durepos hereby gives notice that he has designated the following place as his place of business to wit: 373 Témiscouata Street, Rivière-du-I,oup, P.Q.Me Jacques Langlois, 54560-o Attorney for Aurèle Durepos.D.CURRIER MOVING & CARTAGE CO.LTD.Avis est donné que l'adresse.|xmr la province de Québec, de la compagnie « D.CURRIER MOVING ft CARTAGE CO.LTD.», permis No: 21252-VM est: 20 Longtemps.St-( distant.P.Q.Téléphone:632-1495.Les procureurs de la compagnie, Paquette.Paquette, .1I.\"i('iI -ii Pkhkeai i.r & Rivet.D.CURRIER MOVING & CARTAGE CO.LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"D.CURRIER MOVING & CARTAGE CO.LTD.\".permit No.: 21252-VM is 20 1-ongtemps, St-Constant, P.Q.Telephone: 632-1495.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54561-o Attorneys for the company.INTER-CITY TRUCK LINES LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province di.Québec, des courtiers de la compagnie « INTER-CITY TRUCK LINES LTD ¦>.lesquels sont: Herb Schmidt, 1705 Empire Ave.Saskatoon.Cliff Luchsinger, Box 235, Leroy, James Crawford.517 Ave.« U * South.Saskatoon.Joe O'Hara.Sub P.O.#11.Saskatoon.Ernest Kroeker, 83 Selkirk Cresc.Saskatoon.William Pichler.10 Kootenay Dr.Saskatoon.Al vin Litchen-wald, 2530 Albert Ave.Saskatoon.Don Ramsay.1718 Avenue « D » North.Saskatoon.Bernard Bu-blish.P.O.Box 165.Davidson, tous de la Saskatchewan, sera: 6200 rue St-Patrick, Montréal (Québec) H4E 1B3.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette.54562-0 Perreault & Rivet.INTER-CITY TRUCK LINES LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of: Herb Schmidt, 1705 Empire Ave., Saskatoon, Cliff Luchsinger, Box 235, Leroy, James Crawford.517 Ave.\"U\" South, Saskatoon, Joe O'Hara, Sub P.O.#11.Saskatoon.Ernest Kroeker.83 Selkirk Cresc.Saskatoon.William Pichler, 10 Kootenay Dr., Saskatoon, Alvin Litchenwald.2530 Albert Ave., Saskatoon, Don Ramsay.1718 Avenue \"D\" North, Saskatoon.Bernard Bublish.P.O.Box 165, Davidson, all of the Province of Saskatchewan, and brokers of \"INTER-CITY TRUCK LINES LTD.\".will be: 6200 St.Patrick St.Montreal (Québec) H4E 1B3.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54562-0 Attorneys for the company.KRAUS TRANSPORT LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Quél>ec.de la compagnie « KRAUS TRANSPORT LIMITED », permis no 21708-V est 11.242 est.Boul.Gouin.Rivière-des-Prairies.Montréal.54563-0 Les procureurs de la compagnie.Paquette.Paquette.Perreault & Rivet.KRAUS TRANSPORT LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"KRAUS TRANSPORT LIMITED\", permit No.21708-V is 11.242 East Gouin Blvd., Rivière-des-Prairies, Montreal.54563-o Paquette, Paquette, Perreault & RiVet, Attorneys for the company.CHARLES F.STUART Conformément aux dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi des transports, \"CHARLES F.STUART » donne par les présentes avis qu'il désigne le lieu suivant comme sa place d'affaires: 373 rue lémiscouata.Rivière-du-Loup, P.Q.Le procureur.MOM-o Me Jacques Lanclois.CHARLES F.STUART According to the dispositions of the regulations adopted under the Transport Act \"CHARLES F.STUART\" hereby gives notice that he has designated the following place as his place of business to wit: 373 Témiscouata Street, Rivière-du-Loup, P.Q.Me Jacques Lanclois, 54564-0 Attorney. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 1,5 6635 BENDALIA HOLDINGS INC.LES PLACEMENTS BENDALIA INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « BENDALIA HOLDINGS INC.\u2014 LES PLACEMENTS BENDALIA INC.», constituée en corporation en vertu de la Ix>i des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions île la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 24e jour de septembre 1973.Le secrétaire, 54435 I.Benvexiste.BENDALIA HOLDINGS INC.LES PLACEMENTS BENDALIA INC.Notice is hereby given that \"BENDALIA HOLDINGS INC.\u2014 LES PLACEMENTS BENDALIA INC.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its Charter under the provisiond of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of September, 1973.I.Benvexiste, 54435-0 Secretary.BOUTIQUE HARRIETTS INC.Avis est donné par les présentes que « BOUTIQUE HARRIETTE INC.», une corporation incorporée suivant la Ix>i des compagnies et ayant son bureau chef dans la ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 25 octobre 1973.Le trésorier, 54436-0 Sarah Tarder.BOUTIQUE HARRIETTE INC.Notice is hereby given that \"BOUTIQUE HARRIETTE INC.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, October 25, 1973.Sarah Tarder, 54436-o Treasurer.LE COMPTOIR PAROISSIAL ST-ENFANT-JESUS DE MONTREAL INC.Prenez avis que « LE COMPTOIR PAROISSIAL ST-ENFANT-JESUS DE MONTREAL INC.».corporation duement constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour lui demander la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec le 24e jour d'octobre 1973.Le secrétaire, 54437-0 Gerard Mac Dbrmott.LE COMPTOIR PAROISSIAL ST-ENFANT-JESUS DE MONTREAL INC.Notice is herebv given that \"LE COMPTOIR PAROISSIAL ST-ENFANT-JESUS DE MONTREAL INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in MontreaJ, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to sui-renderits charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 24th day of October 1973.Gerard Mac Dermott, 54437-0 Secretary.EASTERN INVESTORS LIMITED Avis est donné par les présentes que la compagnie « EASTERN INVESTORS LIMITED », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'accepter l'abandon de sa charte et son annulation à compter de la date qui sera fixée par lui.Montréal, le 25 octobre 1973.Le secrétaire-trésorier, 54440 Maureen Couchman.EASTERN INVESTORS LIMITED Notice is hereby given that \"EASTERN INVESTORS LIMITED\", a corporation constituted under the Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for the acceptance of the surrender of its Charter and its cancellation on and from a date to be fixed by him.Montreal, October 25, 1973.Maureen Couchman, 54440-o Secretary-Treasurer.Charte \u2014 Charter \u2014 demandes d'abandon de Applications for Surrender of f)636 QUEBEC OFFICIAL OA/ET TE, Xoeember 10.1973.Uni.10.-,.Xn.!>r, DRIVEWAY SERVICES LTD.Prenez avis que la compagnie « DRTVEWA J SER\\ -[CES LTD.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 octobre 1973.Le président, 54438-o Robkrt V.BabbeR.DRIVEWAY SERVICES LTD.Notice is hereby given that \"DRIVEWAY SERVICES LTD.\" will\" apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, October 26, 1973.Robert V.Barber, 54438-0 President.DUVAL LUMBER INC.Avis est par les présentes donné que « DUVAL LUMBER INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montreal, le 24 octobre 1973.Le* procureurs de la compagnie, (il/Y, Vaii.i.axcoirt, bertram), ,>4439-o Bourgeois & Lai rent.DUVAL LUMBER INC.Notice is hereby given that \"DUVAL LUMBER INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.October 24.1973.Guy, Vaillancoi ht.Bertrand, Bourgeois & Laurent.54439-0 Attorneys for the Company.LES ENTREPRISES MONCEAU LTEE Prenez avis que la compagnie « LES ENTREPRISES MONGEAU LTEE» demandera au ministre «les institutions financières, compagnie et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Signé à l.achinc, P.Q., ce 15e jour d'octobre 1973.Le prneureur de la cnmpagnie.54441-0 Jean-yves Crete, notaire.LES ENTREPRISES MONGEAU LTEE Take notice that \"LES ENTREPRISES MONGEAU LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Lachine, P.Q.this 15th day of October 1973.Jean-yves Crete, notary.54441-o Attorney for the Company.GOLDFIELDS AMUSEMENTS LIMITED Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies «GOLDFIELDS AMUSEMENTS LIMITED» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, que son annulation soit dirigée et qu'une date soit fixée à compter de la quelle la compagnie sera dissoute.Montréal, P.Q., ce 5c jour d'Octobre 1973.U ice-présidente.5t442-o Pierrette M.Gauthier.GOLDFIELDS AMUSEMENTS LIMITED Under the provisionsof the Companies Act, \"GOLDFIELDS AMUSEMENTS LIMITED\" hereby gives notice that it will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for .vi'i'i'ptance \"f it- charier and to direct it- cancellation and fix a date upon and from which it shall be dissolved.Montreal, P.Q., this 5th day of October.1973.Piehrette M.Gauthier, 54442-o l'ice president.LA GRANGETTE ROUGE LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « LA GRANGETTE ROUGE LTEE.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la lx>i des compagnies.[\u2022'ait à London.Ontario, ce 10e jour d'octobre 1973.Le secrétaire.:>Mi W.H.Bremnek.LA GRANGETTE ROUGE LTEE Notice is hereby given that \"LA GRANGETTE ROUGE LTEE.\".a corporation incorporated under the Companies Act having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Companies Act.Dated at London.Ontario this lOlh day of October, 1973.W.H.Bremner.54443-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n' 45 6637 LAROCQUE & GUAY INC.Prenez avis que la compagnie « LAROCQUE & GUAY INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 5567 ave Verdun, Robert Beaulieu, notaire.Verdun 204, Que.54444-0 LAROCQUE & GUAY INC.Notice is hereby given that \"LAROCQUE & GUAY INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Robert Beaulieu, notary 5567 ave Verdun.Attorney for the Company.Verdun 204, Que.54444-o H.C.MCKINNEY, LTD.Avis est par les présentes donné que H.C.MCKINNEY LTD.» dont le bureau principal est situé dans la Ville de Montréal, Province de Québec, fera une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions delà Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 24e jour d'Octobre 1973.Secrétaire, 54445-0 A ht ht h H.Zaldin.H.C.MCKINNEY, LTD.Notice is hereby given that \"H.C.MCKINNEY, LTD.\" which has head office in the City of Montreal province of Québec, will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act.Montreal, Québec, this 24th day of October, 1973.Arthur H.Zaldix, 54445-0 Secretary.MIRENA FILMS DISTRIBUTION INC.Avis est donné par les présentes que « MIRENA FILMS DISTRIBUTION INC.», une corporation incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies , ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives d'abandonner sa charte, Montréal, le 26 septembre 1973.Procureurs de la requérante.Robinson, Sheppard, Borenstein, 54446-o Shapiro & Flam.MIRENA FILMS DISTRIBUTION INC.Notice is hereby given that \"MIRENA FILMS DISTRIBUTION INC.\", a corporation incorporated under Part I of the Companies Act, having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, in order to surrender charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, September 26th, 1973.Robinson, Sheppard, Bohenstein, Shapiro & Flam 54446-0 Attorneys for Petitioner.P.E.PAQUETTE EXCAVATION LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « P.E.PAQUETTE EXCAVATION LTEE », corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social à St-Antoine-des-l.aurcntides, district de Terrebonne, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 7e jour de septembre 1973.(Sceau) Le secrétaire, 54448-0 Léo Pace.PLACEROY INC.Prenez avis que la compagnie « PLACEROY INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Ije procureur, 54449-0 Me Claude Royer, notaire.P.E.PAQUETTE EXCAVATION LTEE Xotice is herebv given that \"P.E.PAQUETTE EXCAVATION LTD.\", a corporation constituted under Part I of the Companies Act and having its head office at St.Antoine-des-Laurentides.district of Terrebonne, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act as and from a date to be fixed by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Dated at Montreal, Québec, this 7th day of September 1973.(Seal) Léo Pace, 54448-0 Secretary.PLACEROY INC.Xotice is given that \"PLACEROY IXC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me Claude Royer, notary.54449-0 Attorney. 6638 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.Xorember 10, 1973, Vol.105, No.45 NABBCO LTD.Avis est donné que la compagnie « NABBCO LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec aux fins d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la 1-oî des compagnies.Daté à Montréal, ce 9e jour d'octobre 1973.Le .secrétaire, 54447-0 L.S.Apeoaii.k.NABBCO LTD.Notice is hereby given that \"NABBCO LTD.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Coo|xratives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 9th day of October 1973.L.S.Apedaile, 54447-o Secretary.ROSITA HOSIERY MILLS LTD.Avis est par les présentes donné que « ROSITA HOSIERY MILLS LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 23 octobre, 1973.Le secrétaire, 54450-o Michael Lerek.ROSITA HOSIERY MILLS LTD.Notice is hereby given that \"ROSITA HOSIERY MILLS LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.October 23, 1973.Michael Lerek, 54450-o Secretary.SOCIETE GENERALE D'ECLAIRAGE DU QUEBEC LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « SOCIETE GENERALE D'ECLAIRAGE DU QUE-BEC LTEE », corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, ayant son siège social dans la Ville Jacques-Cartier.Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 7e jour de scptembie, 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier.54451-0 Roger Maxseai'.SUN FASHIONS LTD.Avis est donné que la compagnie « SUN FASHIONS LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 24 octobre 1973.Les procureurs de la requérante.54452 Fraxkei.& Frank el.SOCIETE GENERALE D'ECLAIRAGE DU QUEBEC LTEE Notice is hereby given that \"SOCIETE GENERALE D'ECLAIRAGE DU QUEBEC LTEE\".a cor-poration constituted under Part I of the Companies Act and having its head office at Ville Jacques-Cartier, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act as and from a date to be fixed by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Dated at Montreal, Québec, this 7th day of September, 1973.(Seal) Roger Maxseai'.54451-0 Secretary-treasurer.SUN FASHIONS LTD.Take notice that \"SUN FASHIONS LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, October 24.1973.Frank el & Fraxkel, 54452-o Attorneys for Applicant.HARRY BKUMER INVESTMENTS LTD.Prenez avis que la compagnie « HARRY RRUMER INVESTMENTS LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 octobre 1973.Le président.d44o()-0 Haiiiiy Bhumeh.HARRY BRUMER INVESTMENTS LTD.Notice is herehv given that \"HARRY BRUMER INVESTMENTS LTD\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.October 26th.1973.Harry Bri;mer.54456-0 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, »» 45 6639 TECHART INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « TECHART INC.», constituant une corporation en vertu de la Loi des compagnies, première partie, par lettres patentes en date du 28 avril 1965.et ayant son siège social dans la ville et le district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 19 octobre 1973.Les procureurs de la compagnie, Bohemikr & Chexard.avocats.5450, Côte-des-Neiges, Montréal 249, Que.54453-0 UNIGENIE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « Unigenie Inc.».constituée en corporation en vertu d^ la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 17 septembre 1973.Les procureurs de la compagnie.54454 Leciiter & Sec; al.INFORMATEL INC.Avis est donné qu'« INFORMATEL INC.».constituée le 11 octobre 1968.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 25 octobre 1973.Les procureurs de la compagnie.Létourneav, Stein, Marseille, 54457-0 Delisle & Larve.HARRY FINKELSTEIN INVESTMENTS LTD.Prenez avis que la compagnie 8 HARRY FINKELSTEIN INVESTMENTS LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies tt coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 octobre 1973.Le président.54458-0 Harry Fixkelsteis.VANIX INC.Avis est par la présente donné que « VANIX IXC », compagnie ayant son siège social à St-Hyacinthe, a adopté un règlement pourvoyant à la distribution de son actif entre ses actionnaires et s'adressera à I honorable ministre des institutions financières, compagnies et coopératives en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Donné à Québec, ce 25 octobre 1973.Le secrétaire.Ô4455-0 Roger Goulet.TECHART INC.Notice is hereby given that \"TECHART INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act, Part I, by letters patent dated April 28th 1965, and having its head office in the city and district of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, 19 October, 1973.Bohemier & Ciibxahd, Lawyers.Attorneys for the Company.5450.Côte-des-Neiges, Montreal 249, Que.54453-0 UNIGENIE INC.Notice is hereby given that \"UNIGENIE INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, September 17, 1973.Leciiter & Segal.54456-0 Attorneys for the Company.INFORMATEL INC.Xotice is given that \"INFORMATEL INC.\".incorporated on October 11, 1968, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, October 25.1973.Létouhxeau, Steix, Marseille, Delisle & Larue.54457-0 Attorneys for the Company.HARRY FINKELSTEIN INVESTMENTS LTD.Notice is herebv given that \"HARRY FINKELSTEIN INVESTMENTS LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, October 26th.1973.Harry Finkelstein.54458-0 President.VANIX INC.Notice is hereby given that \"VANIX IXC\", having its head office in St.Hyacinthe, has adopted a by-law providing for the distribution of its assets among its shareholders and will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Given in Québec, this October 25th.1973.Roger Goulet, 54455 Secretary. r>640 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10.1973, Vol.105, No.j5 LES JUTES VICTORIA INC.Avis est donné que la compagnie « LES JUTES VICTORIA INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social et sa principal place d'affaires en la Ville de Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions île la Loi des compagnies.Les procureurs de la requérante.54459-0 Yaxofsky, Kaiix, Brull & Strauber.MARCHE CHAMPLAIN LTEE Avis est par les présentes donné que « MARCHE CHAMPLAIN LTËE », une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, s'adressera au ministère ries institutions financières, compagmies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 26e jour d'octobre 1973.La secrétaire.54460-o Evelyn Adelman.ORNAMENTAL METAL & MACHINE WORKS LTD.Avis est par les présentes donné que « ORNAMENTAL METAL & MACHINE WORKS LTD.».une corporation dûment incorporée en vertu de la Loi des compagnies qui a son bureau principal dans les ville et district de Montréal, demandera la permission d'abandonner sa charte en vertu de la lx>i des compagnies.Datée à Montréal, le 12e jour d'octobre 1973.(Sceau) Le secrétaire, ô4461-o Jeax Desjardixs.J.K.FIELD SALES CORPORATION Avis est ilonne que la compagnie ¦ J.K.FIELD SALES CORPORATION » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2 octobre, 1973.Les procureurs de la Corporation, 54462-o Campbell & Sand.INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) Avis est donné que la compagnie « INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) » s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le» procureurs de la compagnie.Monette, Clerk.Mi chaud, Bahakett.54599-0 Levesque et Guehette.LES JUTES VICTORIA INC.Notice is hereby given that \"LES JUTES VICTORIA INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act an having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Yaxofsky, Kahx, Brull & Strauber, 54459-0 Attorneys for Petitioner.MARCHE CHAMPLAIN LTEE Notice is hereby given that \"MARCHE CHAMPLAIN LTEE\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Prov-ince of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 26th day of October, 1973.Evelyn Adelman, 54460-o Secretary.ORNAMENTAL METAL & MACHINE WORKS LTD.Notice is herebv given that \"ORNAMENTAL METAL & MACHINE WORKS LTD.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 12th day of October.1973.(Seal) Jean Desjardins.5446 l-o Secretary.J.K.FIELD SALES CORPORATION Notice is given that the company \"J.K.FIELD SALES CORPORATION\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, October 2, 1973.Campbell & Sand, 54462-o Attorneys for the Corporation.INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL) Take notice that the company \"INSTITUT PROVIDENCE (MONTREAL)\" will request from the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the permission to abandon its charter.Monette, Clerk, Michaud, Barakett.Levesque et Guérette, 54569-0 Attorneys for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année.n° 45 6641 Divers Compagnies Miscellaneous Companies J.L.BEAUDET INC.Règlement numéro G Règlement concernant la distribution aux actionnaires de tout l'actif de la compagnie.Que la compagnie distribue parmi les actionnaires de la compagnie tout l'actif de la compagnie, telle distribution devant être faite proportionnellement parmi les actionnaires suivant leurs droits et intérêts respectifs dans la compagnie: Que les administrateurs et officiers de la compagnie soient autorisés et dirigés par les présentes à prendre les moyens nécessaires et à signer les documents requis pour l'accomplissement de ce qui précède.Adopté à l'assemblée des administrateurs du 23 août 1973 et ratifié unanimement par tous les actionnaires à une assemblée générale et.spéciale dûment tenue le 27 septembre 1973.Certifié à Quéhec, ce 26e jour d'octobre 1973.(Sceau) Le président.54572-0 .1.F.Beaudet.STANDARD BOILERS INC.LES CHAUDIERES STANDARD INC.La compagnie « STANDARD BOILERS INC.\u2014 LES CHAUDIERES STANDARD INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.Victor P.Elbert.54463 731417 TERREBONNE GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD.LA CIE GENERALE D'EXPANSION DE TERREBONNE LTEE La compagnie « TERREBONNE GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD.\u2014LA CIE GENERALE D'EXPANSION TERREBONNE LTEE » donne avis qu'elle a diminue de 9 à 6 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.1*.An ohé Gervais.54469 3211-64 LIGNES AERIENNES ASTRO INC.ASTRO AIRLINE INC.La compagnie « LIGNES AERIENNES ASTRO INC.\u2014 ASTRO AIRLINE INC.» donne avis quelle a change le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le président.Fehnani) St-Louis.54464-q 733226 J.L.BEAUDET INC.Bylaw number 6 Bylaw respecting the distribution to the shareholders of all the assets of the company.That the company distribute among the shareholders of the company all the assets of the company, such distribution shall be made on a pro-rata basis among the shareholders according to their respective rights and interests in the company; That the directors and officers of the company be authorized and directed by these presents to take all necessary steps and to sign the required documents for the execution of the foregoing; Adopted at the meeting of the directors of August 23, 1973 and unanimously ratified by all the shareholders at a special general meeting duly held on September 27, 1973.Certified in Québec, this 26th day of October, 1973.(Seal) J.L.Beaudet, 54572 President.STANDARD BOILERS INC.LES CHAUDIERES STANDARD INC.Notice is given that \"STANDARD BOILERS INC.\u2014 LES CHAUDIERES STANDARDS INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.54463-0 Victor P.Elbert, Secretary.731417 TERREBONNE GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD.LA CIE GENERALE D'EXPANSION DE TERREBONNE LTEE Notice is given that \"TERREBONNE GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD.\u2014 LA CIE GENERALE D'EXPAXSION DE TERREBONNE LTEE\" has changed the number of its directors from 9 to 6.P.André Gervais, Secretary.54469-0 3211-64 LIGNES AERIENNES ASTRO INC.ASTRO AIRLINE INC.Notice is given that \"LIGNES AERIENNES ASTRO INC.\u2014 ASTRO AIRLINE INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Fern and St-Louis.President.54464 733226 6642 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 MINES PATINO (QUEBEC) LIMITEE PATINO MINES (QUEBEC) LIMITED La compagnie «MINES PATINO (QUEBEC) LIMITEE \u2014 PATINO MINES (QUEBEC) LIMITED » donne avis qu'elle a changé de 4 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, A.P.Stirling.54553 714618 MINES PATINO (QUEBEC) LIMITEE PATINO MINES (QUEBEC) LIMITED Notice is given that \"MINES PATINO (QUEBEC) LIMITEE \u2014 PATINO MINES (QUEBEC) LIMITED\" has changed the number of its directors from 4 to 5.A.P.Stirling, Secretary-Treasurer.54553-0 714618 AUTO PERFORMANCE SPORT INC.La compagnie « AUTO PERFORMANCE SPORT INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire-trésorier.Paul Bhouillette.54465-0 5233-69 AXWOOD LTD.La compagnie « AXWOOD LTD.» donne avis qu'elle u porté de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.La secrétaire-trésorière.Mme Vera Salzbbrg.54466 15110-62 AUTO PERFORMANCE SPORT INC.Notice is given that \"AUTO PERFORMANCE SPORT INC.\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Paul Brouillette, Seer eta ry-treasurer.54465 5233-69 AXWOOD LTD.Notice is given that \"Axwood Ltd.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Mrs.Vera Salzberg, Secretary-treasurer.54466-0 15110-62 BABY BEAR SHOE COMPANY LIMITED La compagnie « BABY BEAR SHOE COMPANY LIMITED » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire.Pierre Geoffrion.54467-0 3909-47 CENTRODYNE CORP.La compagnie « CENTRODYNE CORP.» donne avis qu'elle a diminue de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.\u2022Iay Shatilla.5446S 3110-68 CIPAL INC.La compagnie « CIPAL INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le président.Jacques Ayotte.54470-o 4171-69 BABY BEAR SHOE COMPANY LIMITED Notice is given that \"BABY BEAR SHOE COMPANY LIMITED\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Pierre Geoffrion.Secretary.54467 3909-47 CENTRODYNE CORP.Notice is given that \"CENTRODYNE CORP.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.54468-0 Jay Shatilla, Secretary.3110-68 CIPAL INC.Notice is given that \"CIPAL INC'.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Jacques Ayotte, President.54470 4171-69 CLUB DE COMPETITION DE N ATATION SAINT-LAURENT INC.La corporation « CLUB DE COMPETITION DE NATATION SAINT-LAURENT INC.» donne avis qu elle a change le nombre de ses administrateurs de 5 à 7./.a secrétaire.Madeleine Pirro.°44''-\" 736199 CLUB DE COMPETITION DE NATATION SAINT-LAURENT INC.Notice is given that \"CLUB DE COMPETITION DE NATATION SAINT-LAURENT INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 7.54471 Madeleine Pirro.Secretari/.736199 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' aimée.«° 45 66-43 LE CLUB DE CURLING LAVIOLETTE La corporation « LE CLUB DE CURLING LA-VIOLETTE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 15 à 17.Le secrétaire, WlLFKID (ÎODIX.54472-0 11703-54 LE CLUB DE HOCKEY LES CONQUERANTS DE LA SARRE INC.La corporation « LE CLUB DE HOCKEY LES CONQUERANTS DE LA SARRE INC.« donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 5.Le secrétaire-trésorier, Michel Lambert.54473-0 726540 LE CLUB DE CURLING LAVIOLETTE Notice is given that \"LE CLUB DE CURLING LAVIOLETTE\" has increased the number of its directors from 15 to 17.Wilfrid Godik, Secretary.54472 11703-54 LE CLUB DE HOCKEY LES CONQUERANTS DE LA SARRE INC.Notice is given that \"LE CLUB DE HOCKEY LES CONQUERANTS DE LA SARRE INC.\" has increased the number of its directors from 4 to 5.54473 Michel Lanlbert, Secretary-Treasurer.726540 JIM RUSSELL INTERNATIONAL RACING DRIVERS CLUB CLUB INTERNATIONAL DES PILOTES DE COURSE JIM RUSSELL La compagnie « JIM RUSSELL INTERNATIONAL RACING DRIVERS CLUB - CLUB INTERNATIONAL DES PILOTES DE COURSE JIM RUSSELL » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 7 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire.I.E.Blanshay.54474 732516 JIM RUSSELL INTERNATIONAL RACING DRIVERS CLUB CLUB INTERNATIONAL DES PILOTES DE COURSE JIM RUSSELL Notice is given that \"JIM RUSSELL INTERNATIONAL RACING DRIVERS CLUB \u2014CLUB INTERNATIONAL DES l'Il.OTES DE COURSE JIM RUSSELL\" has changed the number of its directors from 3 to 7.I.E.Blax.shav.Secretary.54474-0 732516 CLUB LIONS DE LA SARRE INC.La corporation « CLUB LIONS DE LA SARRE INC.\u2022 donne avis qu'elle a change le nombre de ses administrateurs de 12 à 13.Le secrétaire.Michel Lambert.54475-0 730386 CORPS DE CLAIRONS LES CHATELAINES DE LAVAL INC.La corporation « CORPS DE CLAIRONS LES CHATELAINES DE LAVAL INC.» donne avis qu'elle a change le nombre de ses administrateurs de 14 à 4.Le secrétaire.Pacl Couret.54476-o 733025 CLUB LIONS DE LA SARRE INC.Notice is given that \"CLUB LIONS DE LA SARRE INC.\" has increased the number of its directors from 12 to 13.Michel Lambert.Secretary.54475 730386 CORPS DE CLAIRONS LES CHATELAINES DE LAVAL INC.Notice is given that \"CORPS DE CLAIRONS LES CHATELAINES DE LAVAL INC.\" has changed the number of its directors from 14 to 4.54476 Pall Covkf.y.Secretan/.733025 LES ENTREPRISES EM LUC LTEE La compagnie « LES ENTREPRISES EMLUC LTEE » donne avis quelle a change le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.ht secrétaire.Gilles A.Dents.54478-q 723s27 LES ENTREPRISES EMLUC LTEE Notice is given that \"LES ENTREPRISES EMLUC LTEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Gilles A.Denis.Secretary.54478 723*27 6644 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 TRANS-CANADA SIGNS (1967) LTD.LES ENSEIGNES TRANS-CANADA (1967) LTEE La compagnie « TRANS-CANADA SIGNS (1967) LTD.\u2014 LES ENSEIGNES TRANS-CANADA (1967) LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 8.Le secrétaire.Lise St-Jean.54477-0 2563-67 THE EXPORT CORPORATION (OF CANADA) LIMITED Avis est donné que la compagnie « THE EXPORT CORPORATION (OF CANADA) LIMITED » a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le président, S.Silverman.54479 4245-44 GARAGE MASKOUTAIN LTEE La compagnie « GARAGE MASKOUTAIN LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Robert Goyette, 54480-o 5439-66 TRANS-CANADA SIGNS (1967) LTD.LES ENSEIGNES TRANS-CANADA (1967) LTEE Notice is given that \"TRANS-CANADA SIGNS (1967) LTD.\u2014 LES ENSEIGNES TRANS-CANADA (1967) LTEE\" has increased the number of its directors from 6 to 8.Lise St-Jean, Secretary.54477 2563-67 THE EXPORT CORPORATION (OF CANADA) LIMITED Xotice is given that \"THE EXPORT CORPORATION (OF CANADA) LIMITED\" has changed the number of its directors 3 to 5.S.Silverman President.54479-0 4245-44 GARAGE MASKOUTAIN LTEE Notice is given that \"GARAGE MASKOUTAIN LTEE\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Robert Goyette, Secretary.54480 5439-66 GOYETTE TRANSPORT LIMITEE La compagnie « GOYETTE TRANSPORT LIMITEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire.Robert Goyette.54481-0 12685-55 KOMO FASTENERS LTD.Avis est donné que la compagnie « KOMO FASTENERS LTD.» a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le président, S.Silverman.54482 7021-52 MAISON NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE La compagnie « MAISON NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE]» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 11 à 9.La secrétaire.Soeur Laetitia Dutil.54483-0 4235-68 LA SOCIETE D.M.L.LTEE « LA SOCIETE D.M.L.LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire.,,\u201e\u201e Emeric Leonard.o4490-o 723635 GOYETTE TRANSPORT LIMITEE Notice is given that \"GOYETTE TRANSPORT LIMITEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Robert Goyette, Secretary.54481 12685-55 KOMO FASTENERS LTD.Notice is given that \"KOMO FASTENERS LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.54482-0 S.Silverman, President.7021-52 MAISON NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE Notice is given that \"MAISON NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE\" has reduced the number of its directors from 11 to 9.Sister Laetitia Dutil, Secretary.54483 4235-68 LA SOCIETE D.M.L.LTEE Notice is given that \"LA SOCIETE D.M.L.LTEE\" has reduced the number of its directors from 5 to 3.Emeric Leonard.Secretary.54490 723635 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 1,5 6645 OPTIQUE MONARCH (QUEBEC) INC.MONARCH OPTICAL (QUEBEC) INC.La compagnie « OPTIQUE MONARCH (QUE-BEC) INC.-MONARCH OPTICAL (QUEBEC) INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de se.c administrateurs.Le secrétaire adjoint, L.Michael Blumensteix.54484 737922 OPTIQUE MONARCH (QUEBEC) INC.MONARCH OPTICAL (QUEBEC) INC.Notice is given that \"OPTIQUE MONARCH (QUEBEC) INC.\u2014MONARCH OPTICAL (QUE-BEC) INC.\" lias changed the number of its directors from 3 to 4.I.Michael Blumexsteix, Assistant Secretary.54484-0 737922 PEINTURES MONT-ROYAL INC.MOUNT ROYAL PAINTS INC.La compagnie « PEINTURES MONT-ROYAL INC.\u2014 MOUNT ROYAL PAINTS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 5.Le secrétaire.Jetx-P»ri.I.ortif.54485-o 90-70 LE RESTAURANT « EL BARRIO LATINO > INC.La compagnie « LE RESTAURANT « EI.BARRIO LATINO » INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.54486-0 La secrétaire.Maria Yalle.176-69 PEINTURES MONT-ROYAL INC.MOUNT ROYAL PAINTS INC.Notice is given that \"PEINTURES MONT-ROYAL INC.\u2014 MOUNT ROYAL PAINTS INC.\" has reduced the number of its directors from 6 to 5.54485 Jeax-Paul Lohtie, Secretary.90-70 LE RESTAURANT \" EL BARRIO LATINO \" INC.Notice is given that \"LE RESTAURANT \"EL BARRIO LATINO\" INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Maria Valle, Secretary.54486 176-69 QUEBEC BREWERS' SERVICES LIMITED LES SERVICES DES BRASSEURS DU QUEBEC LIMITEE La compagnie « QUEBEC BREWERS' SERVICES LIMITED \u2014LES SERVICES DES BRASSEURS DU QUEBEC LIMITEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 10 à 9.Le secrétaire.Claude Méxahd.146-67 54487-0 SERMLEX INC.La compagnie « SERVILEX INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire.Jeax H.Lafleur.54488-0 1269-68 SIDBEC-FERUNI INC.La compagnie « SIDBEC-FERUNI INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 5.Le secrétaire.Pierre Sauvé.54489-0 737791 QUEBEC BREWERS' SERVICES LIMITED LES SERVICES DES BRASSEURS DU QUEBEC LIMITEE Notice is given that \"QUEBEC BREWERS' SERVICES LIMITED \u2014LES SERVICES DES BRASSEURS DU QUEBEC LIMITEE\" has changed the number of its directors from 10 to 9.Claude Méxahd, Secretary.146-67 54487-o SERMLEX INC.Notice is given that \"SERVILEX IXC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.54488 Jeax H.Lafleur.Secretary.1269-68 SIDHEC-FERUNI INC.Notice is given that \"SIDBEC-FERUNI INC.\" has changed the number of its directors from 7 to 5.54489-0 Pierre Sauvé.Secretary.737791 6646 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 TELE-CABLE VIDEOTRON LTEE La compagnie « TELE-CABLE VIDEOTRON LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire, Frederic W.Benn.54491-0 734665 TELE-CABLE VIDEOTRON LTEE Notice is given that \"TELE-CABLE VIDEOTRON LTEE\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Frederic W.Benn, Secretary.54491 734665 TREITEL-FRANKEL PROPERTIES LTD.La compagnie « TREITEL-FRANKEL PROPERTIES LTD.* donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, VlLIAM FrANKEL.54492 14284-58 ZUM-BURGER CORPORATION La compagnie « ZUM-BURGER CORPORATION » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, Arnold (Ernie) Berexbaoi.54493 709-66 TREITEL-FRANKEL PROPERTIES LTD.Notice is given that \"TREITEL-FRANKEL PROPERTIES LTD.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Viliam Frankel, Secretary.54492-0 14284-58 ZUM-BURGER CORPORATION Notice is given that \"ZUM-BURGER CORPORATION\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Arnold (Ernie) Berenbaum, Secretary-Treasurer.54463-o 709-66 Sièges sociaux Head Offices STANDARD BOILERS INC.LES CHAUDIERES STANDARD INC.1-a compagnie « STANDARD BOILERS INC.\u2014 LES CHAUDIERES STANDARD INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 549, Da-vignon, Dollard-des-Ormeaux, au numéro 1560, Marie Victorin, Saint-Bruno-de-Montarvillc.Le secrétaire, Victor P.Elbert.54463 731417 ARCAM INC.La compagnie « ARCAM INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1767, rue Ste-Fa-mille, Sainte-Foy, au numéro 17, rue St-Jacques, Québec.Le président, Pio Begin.54508-o 725794 ASSOCIATION SOCIALE ET SPORTIVE U A P INC.La compagnie « ASSOCIATION SOCIALE ET SPORTIVE U A P INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033.est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est rue Ontario, en'la ville de Montréal.Le secrétaire, 54509-o Jean Dou ville.STANDARD BOILERS INC.LES CHAUDIERES STANDARD INC.Notice is given that \"STANDARD BOILERS INC.\u2014 LES CHAUDIERES STANDARD INC.\" has transferred its head office from 549 Davignon, Dol-lard-des-Ormeaux, to 1560 Marie Victorin, Saint-Bru-no-de-Montarville.Victor P.Elbert, Secretary.54463-o 731417 ARCAM INC.Notice is given that \"ARCAM INC.\" has transferred its head office from 1767 Ste.Famille Street, Ste.Foy, to 17 St.Jacques Street, Québec.54508-o Pio Begin, President.725794 ASSOCIATION SOCIALE ET SPORTIVE U A P INC.Notice is given that \"ASSOCIATION SOCIALE ET SPORTIVE IJ A P INC.\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Dou ville.54509-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 10 novembre 1973.105' année, u° 1,5 6647 AGENCE G.B.INC.Avis est donné que la compagnie « AGENCE G.B.INC.\", constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 15 août 1973 et ayant son siège social dans la Ville de Laval, a établi son bureau au 278, rue Cadotte à Laval-des-Rapides, district de Montréal À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné a Laval, ce 2 octobre 1973.Président, 54507-o Claude Beauciiamp.AGENCE G.B.INC.Notice is given that \"AGENCE G.B.INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act on August 15th, 1973 and having its head office in Laval, has established its head office at Laval-des Rapides, 278, rue Cadotte.As and from this date, the said office will be considered as main office of the Company.Dated at Laval, this 2nd October 1973.President, 54507-o Claude Beauciiamp.LES ATELIERS PRESTO INC.PRESTO MOTORS WORKS INC.La compagnie « LES ATELIERS PRESTO INC.\u2014PRESTO MOTOR WORKS INC.\u2022 donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 966, rue Rachel est, Montréal, au numéro 2201, rue St-Roch, IjOngueuil.Le secrétaire.nok.mani) sansrecret.54510-o 13506-56 LES ATELIERS PRESTO INC.PRESTO MOTORS WORKS INC.Notice is given that \"LES ATELIERS PRESTO INC.\u2014 PRESTO MOTOR WORKS INC.\" has transferred its head office from 966 Rachel Street East.Montreal, to 2201 St.Roch Street, Longueuil.Norman D SansreOret, Secretary.54510 13506-56 LES USINES METALLURGIQUES DE BLACK LAKE LTEE BLACK LAKE METAL WORKS MFC.LTD.La compagnie « LES USINES METALLURGIQUES DE BLACK LAKE LTEE \u2014 BLACK LAKE METAL WORKS MFG.LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social de rue Bohluc.Black Lake, au numéro 157, 5e Rue, Monlmagny.Le secrétaire.Camille Boulet.54511-0 732504 C VNADIAN AUTOMOTIVE WAREHOUSING LTD.La compagnie « CANADIAN AUTOMOTIVE WAREHOUSING LTD.» donne avis qu'elle a changé, son siège social du numéro 3033.est.rue Notre-Dame en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire.54513-0 Jean Dou ville.LES USINES METALLURGIQUES DE BLACK LAKE LTEE BLACK LAKE METAL WORKS MFG.LTD.Notice is given that \"LES USINES METALLURGIQUES DE BLACK LAKE LTEE \u2014 BLACK LAKE METAL WORKS MFG.LTD.\" has transferred its head effioe from Bolduc Street, Black Lake, to 157 -5th Street, Montmagny.Camille Boulet, Secretary.54511 732504 CANADIAN AUTOMOTIVE WAREHOUSING LTD.Notice is given that \"CANADIAN AUTOMOTIVE WAREHOUSING LTD.\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Dou ville, 54513-o Secretary.LES COMPRIMES MADELON LTEE MADELON TABLETS LTD.La compagnie « LES COMPRIMES MADELON LTEE \u2014MADELON TABLETS LTD.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 4135.Hingston, Montréal, au numéro 215.Montpellier.Saint-Laurent.Le secrétaire.Wolfe M.Fheidmax.54516 729084 LES COMPRIMES MADELON LTEE MADELON TABLETS LTD.Notice is given that \"LES COMPRIMES MADELON LTEE \u2014MADELON TABLETS LTD.\" has transferred its head office from 4135 Hingston, Montreal, to 215 Montpellier, Saint-Laurent.Wolfe M.Freidman, Secretary.54516-0 729084 6648 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 CADEL LTEE La compagnie « CADEI.LTEE » donne avis qu'elle a change son siège social du numéro 3033, est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire.54512-0 Jean Douville.CADEL LTEE Notice is given that \"CADEL LTEE\" has transfered its head office from 3033 Notre-Dame Street East, m the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54512-0 Secretary.CENTRE D'ACCUEIL DE BROSSARD INC.Avis est donné que la compagnie « CENTRE D'AC CUEIL DE BROSSARD INC.», constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec, en date du 25 avril 1973, et ayant son siège social dans la ville de Brossard, Que., a établi son bureau principal au_No 2370 du Boul.Lapinière.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Brossard, Que., ce 18 juin 1973.Le président, 54514-0 Piekrb Trempe.CENTRE D'ACCUEIL DE BROSSARD INC.Notice is herebv given that the \"CENTRE D'ACCUEIL DE BROSSARD INC.\", incorporated by letters patent of the Province of Québec, dated April 25th 1973, with head office in the Town of Brossard, Québec, has established its head office at 2370 Lapinière Blvd.As of the date of publication of the present notice, the said office shall be considered by the Company as its heail office.Signed at Brossard, Québec, this 18th day of June, 1973.Pierre Trempe, 54514 President.CLEO METAL INC.METAL CLEO INC.La compagnie « CLEO METAL INC.\u2014 METAL CLEO INC.» donne avis qu'elle a change son siège social du numéro 2813.St-Narcisse.(iiffard, au numéro 7885, Avenue Sully, appartement 40, Charlesbourg.Le secretaire.Denis Larouche.54515-0 726517 CUISINES CURLY JOE'S LTEE CURLY JOE'S KITCHENS LTD.Avis est par les présentes donné que « CLUSINES CURLY JOE'S LTEE \u2014 CURLY JOE'S KITCHENS LTD.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, a établi son siège social à 4950 rue Fisher, dans la Cité de Saint-Laurent, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donne à Montréal, ce 5 octobre 1973.Secrétaire-trésorier 54517-0 Sam Rubin.CLEO METAL INC.METAL CLEO INC.Notice is given that \"CLEO METAL INC.\u2014 METAL ('LEO INC.\" has transferred its head office from 2813 St.Narcisse, (iiffard, to 7885 Sully Avenue, Apartment 40, Charlesbourg.Denis Larouche, Secretary.54515 726517 CURLY JOE'S KITCHENS LTD.CUISINES CURLY JOES LTEE Notice is herebv given that \"CURLY JOE'S KITCHENS LTD.\u2014 CUISINES CURLY JOES LTEE.\" incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Companies Act.has established its head office at 4950 Fisher Street, Saint-Laurent, Prov-vince of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Ciiven at Montreal, this 5th day of October.1973.Sam Rubin.54517-0 Secretary-Treasurer.DUMONT EXPRESS LTEE La compagnie « DUMONT EXPRESS LTEE » donne avis qu'elle a change son siège social de Route du Sault.Saint-Romuald-d'Etchemin.au numéro 2725.rue Dalton, Sainte-Foy.Le secrétaire.Jean Pelletier.54518-0 15237-62 DUMONT EXPRESS LTEE Notice is given that \"DUMONT EXPRESS LTEE\" has transferred its head office from Route-du-Sault.St.Romuald-d'Etchemin.to 2725 Dalton Street.Ste.Foy.Jean Pelletier.Secretary.54518 15237-62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.n° 45 6649 DYMEX PRECISION CO.LTD.Avis est donné que « DYMEX PRECISION CO.LTD.», incorporée en vertu de la première partie de la Loi des companies, par lettres patentes en date du 17 mars 1969, a transporté son siège social du 4241, boul.Industriel, en les ville et district de Montréal, au 6270, ouest, rue Notre-Dame, en les ville et district de Montréal.Montréal, le 6e jour du mois de septembre 1973.Le secrétaire.(Sceau) Ibolya Kustowki.54519-0 1190-1969 DYMEX PRECISION CO.LTD.Notice is hereby given that \"DYMEX PRECISION CO.LTD.\".incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated March 17th 1969, has moved its head office from 4241, Industrial Blvd., in the city ami district of Montreal to 6270, Notre-Dame Street West in the city and district of Montreal.Montreal, this 6th day of the month of September.1973.Ibolya Kustowki, (Seal) Secretary.54519-0 1190-1969 LES ENTREPRISES A.A.INC.A.A.ENTERPRISES INC.La compagnie « LES ENTREPRISES A.A.INC.VA ENTERPRISES INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du 1540, avenue Summerhill, Montréal, au 990, rue Castelneau, Douville.Le secrétaire.Thomas J.Gorman.54520 4965-69 LES ENTREPRISES A.A.INC.A.A.ENTERPRISES INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES A.A.INC.\u2014 A.A.ENTERPRISES INC\" has transferred its head office from 1540 Summerhill Avenue, Montreal, to 990 Castelneau Street, Douville.Thomas J.Gorman, Secretary.54520-o 4965-69 ENTREPRISES BLANCHET LTEE La compagnie « ENTREPRISES BLANCHET LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2431, rue Vitré, St-Pascal, Québec, au numéro 324, boulevard Rochette, Beauport.Le secrétaire.Marcel Blanciiet.54521-0 3489-48 ENTREPRISES BLANCHET LTEE Notice is given that \"ENTREPRISES BLANCHET LTEE\" has transferred its head office from 2431 Vitré Street, St.Pascal, Québec, to 324 Rochette Boulevard, Beauport.Marcel Blanciiet, Secretary.54521 3489-48 LES ENTREPRISES CUBIC LTEE La compagnie « LES ENTREPRISES CUBIC LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social de Saint-Jérôme à Saint-Sauveur-des-Monts.Le président, Gilles Huot.54522-0 731552 G G R PIECES D'AUTOS LTEE LES ENTREPRISES CUBIC LTEE Notice is given that \"LES ENTREPRISES CUBIC LTEE\" has transferred its head office from Saint-Jérôme to Saint-Sauveur-des-Monts.Mr.Gilles Huot, President.54522-0 731552 G G R AUTO PARTS LTD.Avis est donné que « G G R PIECES D'AUTOS LTEE » compagnie constituée en corporation par lettres patentes, le 29 juillet 1968 et ayant son bureau principal à Trois-Rivières où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui à 2215, rue Bellefeuille, l'a transporté à 2550, rue St-Denis, Trois-Rivières.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Trois-Rivières, ce 22 octobre 1973.Les Procureurs de la compagnie.GlROUARU, BeAUMIER, 54523-o Richard & RoBEBGE Notice is hereby given that \"G G R AUTO PARTS LTD.\" company incorporated by letters patent, on the July 29th, 1968, ami having its head office in Trois-Rivières, where its office was situated up to to-day, at 2215, rue Bellefeuille, has moved it to 2550, St-Denis Street, Trois-Rivières.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Given at Trois-Rivières.this October 22 ,1973.Girouard, Beai'mier, Richard, & Roberc.e.54523-0 Attorneys for the Company. 6650 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 GREENFIELD PARK SHOPPING CENTRE LLMITED Avis est donné que la compagnie ci-dessus mentionnée a transféré son siège social au 550, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec.Daté ce 22e jour d'août 1973.(Sceau) Le secrétaire adjoint, 54524-0 I).A.Burns.R OX HAM PROPERTIES, LIMITED LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE Avis est donné que la compagnie « ROXHAM PROPERTIES.LIMITED \u2014 LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE », constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 août, 1972, at ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau à la suite 3411, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 30e jour d'août 1973.Le président, 54525-0 J.Stanley Kennedy, GREENFIELD PARK SHOPPING CENTRE LLMITED Take notice that the location of the head office of the above company has been changed to 550 Sherbrooke St.Yv'., Montreal, Québec.Dated this 22nd day of August 1973.(Seal) D.A.Burns, 54524 Assistant-Secretary.ROXHAM PROPERTIES, LIMITED LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE Notice is herebv given that \"ROXHAM PROPERTIES.LIMITED \u2014 LES IMMEUBLES ROXHAM.LIMITEE\", incorporated by letters patent dated August 9, 1972, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at Suite 3411, 1 Place Ville Marie, Montreal, Québec.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 30th day of August 1973.J.Stanley' Kennedy, 54525-0 President.LES IMPORTATIONS ASCA INC.La Compagnie « LES IMPORTATIONS ASCA INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033, est, rue Notre-Dame, en la Ville de Montreal, au numéro 7025, est, rue Ontario en la ville de Montréal.Le secretaire, 54526-0 Jean Douville.MARGWEN INC.Avis est par les présentes donné que « MARGWEN INC.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies en date du 20 août 197.3, et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 500 Place d'Armes, suite 1200, Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 3 octobre 1973.Le président.54527-0 O.A.Lackbnbauer.INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LLMITED La compagnie « INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033.esL rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire.54528-0 Jean Douville.LES IMPORTATIONS ASCA INC.Notice is given that \"LES IMPORTATIONS ASCA INC.\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54526-0 Secretary.MARGWEN INC.Notice is hereby given that \"MARGWEN INC.\".incorporated by letters patent issued under Part I of the Québec Companies Act dated August 20, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at No.500 Place d'Armes, Suite 1200, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 3rd day of October, 1973.O.A.Lackenbauer, 54527-0 President.INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED Notice is given that \"INTERNATIONAL ELECTRIC COMPANY LIMITED\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54528-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année.n° 45 6651 MONTREAL MILLING CUTTER CO.INC.La compagnie « MONTREAL MILLING CUTTER CO.INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3737.boulevard Métropolitain est, chambre 1003.Montréal, au numéro 821.rue Salaberry.Laval.Le secrétaire.John Mc Nally.54529-0 396-70 NEOPRO INC.Avis est donné que la compagnie « NEOPRO INC.9 constituée en corporation, dans la province de Québec, par lettres patentes en date du premier décembre mil neuf cent soixante-douze, et ayant son siège social dans la Ville de Laprairie où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui, rue Lallemand, l'a transporté rue St-Laurent, numéro 159, de la même ville.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considère par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Laprairie, ce vingt-et-un septembre mil neuf cent soixantre-trtize.Le président, Michel Fol'rnikk.54530-o 729491 MONTREAL MILLING CUTTER CO.INC.Notice is given that \"MONTREAL MILLING CUTTER CO.INC.\" has transferred its head office from 3737 Métropolitain Boulevard East, Room 1003.Montreal, to 821 Salaberry Street, Laval.John Mc Nally, Secretary.54529-0 396-70 NEOPRO INC.Notice is given that \"NEOPRO INC.\" incorporated in the Province of Québec by letters patent dated December first one thousand nine hundred seventy-two, and having its head office in the Town of Laprairie, where said office was located until the present day, on Lallemand Street, has transferred said office to 159 St.Laurent Street, in said Town.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Given in Laprairie, this twenty-first day of September, one thousand nine hundred seventy-three.Michel Fournier, President.54530 729491 P.C.L.CONSTRUCTION INC.Avis est donné que la compagnie « P.C.L.CONSTRUCTION INC.\u2022 constituée en corporation par lettres patentes datées du 6 avril 1972 a son siège social dans le district de Montréal, au 3730 est.boul.Métropolitain, suite 301.à Montréal.Le secrétaire, 54531-0 Henri Paqun.P.C.L.CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"P.C.L.CONSTRUCTION INC.'.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent issued on April, 6th 1972 has its head office in the District of Montreal, 3730 east Métropolitain blvd, room 301, Montreal.Henri Paquin, 5453 l-o Secretary.QUEBEC VALVE & FITTING INC.VALVE & RACCORD QUEBEC INC.La compagnie « QUEBEC VALVE & FITTING INC.\u2014VALVE & RACCORD QUEBEC INC.», donne avis qu'elle a transféré son siège social de Québec au numéro 1308, avenue Carswell, Sainte-Foy.La secrétaire, Mme P.Marchand.54532 732291 QUEBEC VALVE & FITTING INC.VALVE & RACCORD QUEBEC INC.Notice is given that \"QUEBEC VALVE & FITTING INC.\u2014VALVE & RACCORD QUEBEC INC.\" has transferred its head office from Québec to 1308 Carswell Avenue, Sainte-Foy.Mme P.Marchand, Secretary.54532-0 732291 LA SOCIETE DEMOSTHENE INC.Avis est donné que « LA SOCIETE DEMOSTHENE INC.», constituée en corporation sous le nom de « L'INSTITUT DE PERSONNALITE INC.» en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes émises en date du 2 juillet 1965, a changé son siège social du 2850 est, rue Sherbrooke.Montréal, P.Q.à 1 Place Ville Marie, Montréal, P.Q.Donné à Montréal, le 9 octobre 1973.Présidente, 54534-0 Andrée Lebobuf.LA SOCIETE DEMOSTHENE INC.Notice is hereby given that \"LA SOCIETE DEMOSTHENE INC.\".incorporated under the name of \"L'INSTITUT DE PERSONNALITE INC.\" under Part 1 of the Companies Act by Letters Patent granted on July 2nd, 1965, has changed its head office from 2850 Sherbrooke Street East, Montreal, P.Q.to 1 Place Ville Marie, Montreal, P.Q.Given at Montreal, this 9th day of October, 1973.Andrée Leboeuf, 54534-0 President. 6652 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.j5 SAET INC.La compagnie « SAET INC.»donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 10161, rue Milieu, Montréal, à Cité Nature, Saint-Télesphore.Le secrétaire.Roger Simark.54533-0 716416 SPECIALITE TRACTION LTEE U compagnie « SPECIALITE TRACTION LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033.est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, an la ville de Montréal.Le secrétaire, 54535-0 Jean Douville.TWIN EQUIPMENT SUPPLY LTD.La compagnie « TWIN EQUIPMENT SUPPLY LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033.est.rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Ise secrétaire, 54536-0 Jean Douville.UAP INC.La compagnie « UAP INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033, est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire, 54537-0 Jean Douville.SAET INC.\"SAET INC.\" gives notice that it has transferred its head office from 10161 Millen Street, Montreal, to Cité Nature, St.Télesphore.Roger Simard, Secretary.54533 \"16416 SPECIALITE TRACTION LTEE Notice is given that \"SPECIALITE TRACTION LTEE\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54535.0 Secretary.TWIN EQUIPMENT SUPPLY LTD.Notice is given that \"TWIN EQUIPMENT SUPPLY LTD.\" has transfered its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.54530-o Jean Douville, Secretary.UAP INC.Notice is given that \"UAP INC.\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54537-q Secretary.UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED La compagnie « UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033, est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire, 54538-0 Jean Douville.LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE Avis est donné que la compagnie « LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE ».constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies le 9 décembre 1971 et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 235, est, boulevard Dorchester, en les ville et district de Montréal, l'a transporté au numéro 1.Place Ville Marie, suite 1734 en les villes et district de Montréal, au soin de Mtres Selinger.Robert & Leng-vari.Montréal, le 19 septembre 1973.Le secrétaire.5-4541-0 Gerard Hogue.UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LLMITED Notice is given that \"UNITED AUTO PARTS OF VALLEYFIELD LIMITED\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.Jean Douville, 54538-0 Secretary.LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE Notice is hereby given that \"LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated December 9, 19T1 has moved its head office from 235.Dorchester Blvd.East, in the City and District of Montreal, to 1.Place Ville Marie, suite 1734.in the City and District of Montreal, care of Mes.Selinger, Robert & Lengvari.Montreal, September 19th, 1973.Gerard Hogue, 54541-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6653 UNITED AUTO PARTS (SOREL) LTD.La compagnie « UNITED AUTO PARTS (SOREL) LTD.« donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3033, est, rue Notre-Dame, en la ville de Montréal, au numéro 7025, est, rue Ontario, en la ville de Montréal.Le secrétaire, 51539-0 Jean Douville.UNITED AUTO PARTS (SOREL) LTD.Notice is given that \"UNITED AUTO PARTS (SOREL) LTD.\" has transferred its head office from 3033 Notre-Dame Street East, in the City of Montreal, to 7025 Ontario Street East, in the City of Montreal.54539-0 Jean' Douville, Secretary.UNIVERSAL IMPEX CO.LTD.Avis est donné par les présentes que « UXIVERSAI.IMPEX CO.LTD.», incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes datées du 30 août 1960.a déménagé son siège social du 515, rue Chatham, dans la ville de Montréal, à 350.ouest, rue Louvain.dans la ville de Montréal.Montréal, le lie jour d'octobre 1973.54540-o Le président.Carlos Schuster.UNIVERSAL IMPEX CO.LTD.Notice is hereby given that \"UXIVERSAL IMPEX CO.LTD.\".incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated August 30.1960.has moved its head office from 515, Chatham Street, in the City of Montreal, to 350, Louvain Street West, in the City of Montreal.Montreal, this 11th dav of October.1973.54540-o Carlos Schuster, President.MANOIR HADDON INC.HADDON HALL INC.Avis est donné que la compagnie « MANOIR HADDON INC.\u2014 HADDON HALL INC.».constituée en corporation dans la province de Québec, sous la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 10 octobre 1973.et ayant son siège social dans la ville de Montréal a établi son bureau au numéro 800 Carre Victoria, Suite 2401.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, Québec, ce 10e jour d'octobre 1973.Le secrétaire.54542-0 Robert S.Carswell.MANOIR HADDON INC.HADDON HALL INC.Xotice is given that \"MANOIR HADDON INC.\u2014 HADDON HALL INC.\".incorporated in the Province of Québec under Part I of the Companies Act by letters patent dated the 10th day of October.1973 and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 800 Victoria Square, Suite 2401.Upon, from and after the date of this notice, the said office will be considered by the Company as being its head office.Given at Montreal, Québec, this 10th day of October, 1973.Robert S.Carswell.54542-0 Secretary.Demande à la Législature Application to Legislature Église Béthanie Avis public est donné par les présentes que l'Eglise Béthanie, une Église protestante particulière selon la Loi de la constitution de certaines Églises, 1964 R.S.Q., c.305, s'adressera au lieutenant-Gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'acquisition des pouvoirs d'un corps constitué en corporation, le tout suivant ladite Loi de la constitution de certaines Églises.Montréal, ce 30e jour d'octobre 1973.Les procureurs de la requérante, Martixeau, Walker, Allison, Beaulieu, 54568-45-4-0 Phelan & Mackell.Église Béthanie Public notice is hereby given that Église Béthanie, an individual Protestant Church within the meaning of the Church Incorporation Act.1964 R.S.Q., ch.305.will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for incorporation under the said Church Incorporation Act.Montreal, this 30th day of October 1973.Martixeau, Walker, Allison, Beaulieu, Piielan & Mackell, 54568-45-4-0 Attorneys for Petitioner. 6654 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Liquidation \u2014 Loi de la LAVE-AUTO DEUX MINUTES INC.TWO MINUTES CAR WASH INC.Avis est donné que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « LA\\ E-AUTO DEUX MINUTES INC.\u2014TWO MINUTES CAR WASH INC.-, tenu à Québec, le 31 mars 1973, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Ix>i de la liquidation des compagnies, et que M.Robert Thibeault a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjahdins, 54567-0 4015-66 Winding-Up Act LAVE-AUTO DEUX MINUTES INC.TWO MINUTES CAR WASH INC.Notice is given that at a special general meeting of the shareholders of \"LAVE-AUTO DEUX MINUTES IXC.\u2014 TWO MINUTES CAR WASH INC.\", held at Québec, on March 31, 1973, it was resolved that the affairs of said Company be wound up and that the latter be dissolved, in conformity with the Winding-up Act, and that Mr.Robert Thibeault be appointed liquidator.Pierre Desjahdins.Director of the Companies Service.54567 4015-66 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Pierrefonds Avis est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la Ville de Pierrefonds, seront vendus à l'enchère publique, en la Salle du conseil de l'Hôtel de Ville sise au 11072 boulevard C.ouin ouest, le MARDI, le VINGT-SEPTIÈME jour de NOVEMBRE 1973.à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêt, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.City of Pierrefonds Xotice is hereby given that the immovables described hereinunder.situated in the City of Pierrefonds, will be sold by public auction, in the City Hall of the City of Pierrefonds, situated at 11072 Gouin Boulevard West, on TUESDAY, the TWENTY-SEVENTH day of NOVEMBER 1973.at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions Les Entreprises Roger Pilon Inc.Avec bâtisses dessus érigées.Davar Construction Inc.Avec bâtisses dessus érigées.Lumont Holding Limited.Avec bâtisses dessus érigées.Gepner Realties Inc.Cette partie de lot mesure mille neuf cent deux pieds 0.902') dans sa ligne nord-est, mille huit cent quatre-vingt-un pieds (1,881') dans sa ligne sud-ouest, cent quarante-sept pieds et deux dixièmes de pied (1-17.2') dans sa ligne nord-ouest et cent soixante-sept pieds (167') dans sa ligne sud-est.Cette partie de lot contient en superficie deux cent quatre-vingt-six mille deux cent dix-neuf pieds carrés et cinq dixièmes de pied carré (286,219.5 pi.ca.) mesure anglaise.Cette partie de lot est bornée au nord-est par une partie des lots 131 et 132.au sud-ouest par une partie du lot 139.au sud-est par le lot 247, (Ville de Dollard-des-Ormeaux) et au nord-ouest par une partie du lot 133.51.51 52 With buildings thereon erected.69.With buildings thereon erected.107.109-5.109-6.4.294.With buildings thereon erected.P.133.This part of lot measures one thousand nine hundred and two feet (1,902') in its northeast line, one thousand eight hundred and eighty-one feet (1,881') in its southwest line, one hundred and forty-seven feet and two tenths of a foot (147.2') in its northwest line and one hundred and sixty-seven feet (167') in its southeast line.This part of lot has an area of two hundred and eighty-six thousand two hundred and nineteen square feet and five tenths of a square foot (286,219.5 sq.ft.), English measure.This part of lot is bounded to the northeast by part of lots 131 and 132, to the southwest by part of lot 139, to the southeast by lot 247 (Town of Dollard-des-Ormeaux) and to the northwest by a part of lot 133. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 10 novembre 1973, 105' année, ri\" 45 6655 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadast re Subdivisions Gepner Realties Inc.P.139.Cette partie de lot mesure mille huit cent quatre-vingt-un This part of lot measures one thousand eight hundred and pieds 0,881') dans sa ligne nord-est.mille huit cent soixante- eighty-one feet (1,881') in its northeast line, one thousand huit pieds et huit dixième de pied (1.868.8') dans sa ligne sud- eight hundred and sixty-eight feet and eight tenths of a foot ouest, cent quarante-cinq pieds (145') dans sa ligne nord-ouest (1,868.8') in its southwest line, one hundred and forty-five et cent cinquante-deux pieds (152') dans sa ligne sud-est.feet (145') in its northwest Une and one hundred and fifty-two feet (152') in its southeast line.Cette partie de lot contient en superficie deux cent soixante- This part of lot has an area of two hundred and sixty-five cinq mille sept cent soixante-quinze pieds carrés et huit thousand seven hundred and seventy-five square feet and dixièmes de pied carré (265.775.8 pi.ca.).mesure anglaise.eight tenths of a square foot (265,775.8 sq.ft.), English Cette partie de lot est bornée au nord-est par une partie du measure.This part of lot is bounded to the northeast by part lot 133, au sud-ouest par une partie du lot 140.au nord-est of lot 133.to the southwest by part of lot 140, to the northeast par le lot 247 (Ville de Dollard-des-Ormeaux) et au nord-ouest by lot 247 (Town of Dollard-des-Ormeaux) and to the north-par une partie du lot 139.west by a part of lot 139.Roag Realty Inv.Co.P.153.Borné en front au nord-est parla rue René-Emard (153-46), Bounded in front towards the northeast by René-Emard au sud-est par une autre partie du lot 153 appartenant à Les Street (153-46).towards the southeast bv another part of lot Entreprises Roger filon Inc.au sud-ouest par une partie du lot 153, property of Les Entreprises Roger Pilon Inc., towards the 153-44 et au nord-ouest par le lot 153-54.southwest by a part of lot 153-44 and towards the northwest by lot 153-54.Cette partie de lot mesure sept cent vingt-sept pieds et trois This part of lot measures seven hundred and twenty-seven dixièmes de pied (727.3') au nord-est; deux cent pieds et qua- feet and three tenths of a foot (727.3') towards the northeast; rante-deux centièmes de pied (200.42') au sud-est; six cent two hundred feet and forty-two hundredths of a foot (200.42') soixante-dix-sept pieds et neuf dixièmes de pied (677.9') au towards the southeast; six hundred and seventy-seven feet and sud-ouest et deux cent trois pieds et trois dixièmes de pied nine tenths of a foot (677.9') towards the southwest, and two (203.3') au nord-ouest.hundred and three feet and three tenths of a foot (203.3') towards the northwest.Contenant en superficie cent quarante-deux mille deux cent Containing a superficial area of one hundred and forty-two quarante pieds carrés (142,240 pi.ca.), mesure anglaise.thousand two hundred and forty square feet, English measure (142,240 sq.ft.).Shell Construction Co.P.174.Shell Construction Co.174.P.6.Shell Construction Co.174 .68.Shell Construction Co.P.175.De figure trapézoïdale, borné au nord-ouest par le cadastre Of trapezoidal figure, bounded towards the northwest by officiel du Village de Sainte-Geneviève, au nord-est par une the official cadastre for the Village of Ste-Geneviève, towards partie du lot 174, au sud-est par le boulevard Pierrefonds the northeast by part of lot 174.towards the southeast by (175-14) et au sud-ouest par une autre partie dudit lot 175.Pierrefonds Boulevard (175-14).towards the southwest by Cette partie de lot mesure trois cent quatre-vingt-un pieds another part of lot 175.(381') de largeur perpendiculaire par des profondeurs de cinq This part of lot measures three hundred and eighty-one cent soixante-quatre pieds (564') dans sa ligne sud-ouest et six feet (381') in perpendicular width by depths of five hundred cent dix pieds (610') dans sa ligne nord-est.Cette partie de lot and sixty-four feet (564'i in its southwest line and six hundred contient en superficie deux cent vingt-trois mille six cent and ten feet (610') in its northeast line.quarante-sept pieds carrés (223.647.pi.ca.), mesure anglaise.This part of lot contains a superficial area of two hundred and twenty-three thousand six hundred and forty-seven square fest (223,617').English measure.Shell Construction Co.De figure irrégulière, bornée au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (175-14).au nord-est par une partie non subdivisée du lot 174, au sud-est par la rue Gratton (175-13) et au sud-ouest par une autre partie non subdivisée du lot 175.Cette partie de lot mesure trois cent quatre-vingt-un pieds (381') de largeur perpendiculaire par une profondeur de deux cent quatre-vingt-cinq pieds (285').Cette partie de lot contient en superficie cent huit mille huit cent vingt pieds carrés (108,820') mesure anglaise.P.175.Of irregular figure, bounded towards the northwest by Pierrefonds Boulevard (175-14).towards the southeast by Gratton Street (175-13), towards the southwest by another unsubdivided part of lot 175.and towards the northeast by an unsubdivided part of lot 174.This part of lot measures three hundred and eighty-one feet (381') in perpendicular width by a depth of two hundred and eighty-five feet (285').This part of lot contains a superficial area of one hundred and eight thousand eight hundred and twenty square feet (10S.820sq.ft.), English measure.The 183 Corporation.,.Premiere parcelle: De figure irrégulière, bornée en front au sud-est par le boulevard Pierrefonds (P1S3), au sud-ouest par une partie du lot 116, les lots 116-22.116-16 (rue) et 116-15 du cadastre officiel pour le Village de Sainte-Geneviève, au nord-ouest par une partie du lot 119 du cadastre officiel du Village de Sainte-Geneviève et au nord-est par les lots 182-3, 182-4 et 182-60.P.183.First parcel: Of irregular figure, bounded in front towards the southeast by Pierrefonds Boulevard (P1R3) towards the southwest by part of lot 116.lots 116-22.116-16 (street) and 116-15 of the official cadastre for the Village of Ste.Geneviève, towards the northwest by part of lot 119 (Village of Ste.Geneviève) and towards to northeast by lots 182-3, 182-4 and 182-60. 6636 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions Cette parcelle de terrain mesure quatre cent quatre-vingt-dix pieds et quatre-vingt-douze centièmes de pied (490.92') au sud-est, quatre cent vingt et un pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (421.89') au sud-ouest, quatre cent sept pieds et huit dixièmes de pied (407.8') au nord-ouest et deux cent soixante-deux pieds et trente et un centièmes de pied (262.31') au nord-est.Contenant en superficie 3.37 arpents carrés.Deuxième parcelle: De figure irrégulière, bornée au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (P183).au nord-est par une partie du lot oiiginaire 182.les lots 182-10 à 182-13 inclusivement, 182-18 â 182-23 inclusivement.182-34.182-56, 182-61-1 et une partie du lot 182-61, au sud-ouest par des parties non subdivisées des lots originaires 182.184 (Paroisse de Sainte-Geneviève, et une partie du lot 116 (Village de Sainte-Geneviève).Cette parcelle de terrain mesure quatre-vingt-dix-huit pieds et soixante-quatre centièmes de pied (98.64') dans une ligne droite et quatre cent quatre-vingt-dix pieds et trente-sept centièmes de pied (490.37') le long d'une courbe d'un rayon de 1,860 pieds sur le boulevard Pierrefonds, deux mille quatre cent quatre-vingt-huit pieds (2,488') au nord-est, deux cent dix pieds (210') et cent soixante-quatorze pieds (174') dans ses lignes sud-est sur le résidu du lot 183, soixante et onze pieds (71') au sud-ouest sur le p'sidu du lot 183 et deux mille soixante-sept pieds (2.067') dans sa ligne sud-ouest sur la partie du lot 184 (Paroisse de Sainte-Geneviève) et la partie du lot 116 (Village de Sainte-Geneviève).Contenant en superficie 23.6 arpents carrés.Gepner Realties Inc.Première parcelle: De figure irréguiière, borné au sud-est par une partie du lot 188 (propriété de Arden Construction Co.Ltd.) par le lot 188-14 (rue) et par le lot 18S-13; au sud-ouest par une partie du lot 192: au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (P.188) et au nord-est par une partie du lot 187-41.par le lot 187-42 (rue Claude), par le lot 187-43, une partie du lot 187 et par une partie du lot 188.propriété de Arden Construction Co.Ltd.Cette dite partie de lot mesure quatre-vingt-dix-neuf pieds et quarante-quatre centièmes de pied (99.44pi> et cent soixante-quinze pieds et quatre dixièmes de pied (175.4pi> dans ses limites sud-est; huit cent cinquante pieds plus ou moins (850 pi plus ou moins) au sud-ouest: deux cent quatre-vingt-douze piedr (292.0pi) au nord-ouest et trois cent trente-cinq pieds (335.0pi) et six cent pieds (600.0pi) dans ses limites nord-est.Deuxième parcelle: Do figure irréguiière, borné au sud-est par le boulevard Pierrefonds (P, 188); au sud-ouest par une partie du lot 192; au nord-ouest par le boulevard Gouin, et au nord-est par les lots 187-6, 187-7 (rue), 187-10, 187-11, 187-14 (rue), 187-17, 187-18, 187-21 (rue).187-22.187-27, 187-28 (rue), 187-29, 187-34 et une partie du lot 187-35.Cette partie de lot mesure deux cent quatre-vingt-douze pieds (292.0pi) au sud-est; mille cent trente-huit pieds plus ou moins (1,138 pi plus ou moins) au sud-ouest; deux cent quatre-vingt-cinq pieds plus ou moins (285.0 pi plus ou moins) au nord-ouest et mille cinquante pieds (l,050.0pi) au nord-est.Ces deux parties du lot 188 contiennent en superficie totale quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent, soixante-dix-sept pieds carrés, mesure anglaise, (483,777pi.ca.).Avec bâtisses dessus érigées The Two Hundred Nineteen Corp.De figure irrégulière, borné au nord-ouest par les lots 219-50.219-51 (rue), 219-52, 219-53 et 219-54, au nord-est par le This said parcel of land measures four hundred and ninety feet and ninetv-two hundredths of a foot (490.92') towards the southeast, four hundred and twenty-one feet and eighty-nine hundredths of a foot (421.89') towards the southwest, four hundred and seven feet and eight tenths of a foot (407.8 ) towards the northwest and two hundred and sixty-two feet and thirty-one hundredths of a foot (262.31') towards the northeast.Containing a superficial area of 3.37 square arpents.Second parcel: Of irregular figure, bounded towards the northwest by Pierrefonds Boulevard (P183).towards the northeast by part of lot 182.lots 182-10 to 182-13 inclusively, 182-18 to 182-23 inclusively, 182-34.182-56, 182-61-1 and part of lot 182-61, towards the southwest by part of lot 182.part of lot 184 (Parish of Ste-Geneviève) and part of lot 116 (Village of Ste-Geneviève., , This said parcel of land measures ninety-eight feet and sixty-four hundredths of a foot (98.64') in a straight line and four' hundred and ninety feet and thirty-seven hundredths of a foot (490.37') along a curve of a radius of 1.860 feet on Pierrefonds Boulevard, two thousand four hundred and eighty-eight in its southwest line on the residue of lot 183 and two thousand and sixtv-seven feet (2.067') in its southwest line on part of lot 184 (Parish of Ste-Geneviève) and part of lot 116 (Village of Ste-Geneviève).Containing a superficial area of 23.6 square arpents.P.188.First parcel: Of irregular figure, bounded towards the southeast by part of lot 188 (property of Arden Construction Co.Ltd), by lot 188-14 (street) and by lot 188-13; towards the southwest by part of lot 192; towards the northwest by Pierrefons Blvd.(P188) and towards the northeast by part of lot 187-41.lot 187-42 (Claude Street), lot 187-43; part of lot 187 and by part of lot 1S8.property of Arden Construction Co.Ltd.This said part of lot measures ninety-nine feet and forty-four hundredths of a foot (99.44ft) and one hundred and seventy-five feet and four tenths of a foot (175.4ft) in its southeast limits; eight hundred and fifty feet more or less (850ft) in its southwest limit; two hundred and ninety-two feet (292 ft) in its northwest limit and three hundred and thirty-five feet (335ft) and six hundred feet (600(t) in its northeast limits.Second parcel: Of irregular figure, bounded towards the southeast by Pierrefonds Blvd.(P188); towards the southwest by part of lot 192; towards the northwest by Gouin Blvd; and towards the northeast by lots 187-6.187-7 (street), 187-10, 187-11, 187-14, (street), 187-17, 187-18, 187-21 (street), 187-22.187-27, 187-28 (street), 187-29, 187-34 and part of 187-35.This said part of lot measures two hundred and ninety-two feet (292ft) in its southeast limit, one thousand one hundred and thirty-eight feet more or less (1,138ft) in its southwest limit, two hundred and eighty-five feet more or less (285ft) in its northwest limit and one thousand fifty feet (1.050ft) in its northeast limit.These two part of lot 188 contain a total superficial area of four hundred and eighty-three thousand seven hundred and seventy-seven square feet, English measure (483,777sq.ft.).With buildings thereon erected .P.219.Of irregular figure, bounded towards the northwest by lots 219-50, 219-51 (street).219-52, 219-63 and 219-54, towards GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6657 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions résidu du lot 219, au sud-est par le cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne et au sud-ouest par le lot 220 et dans une autre petite ligne sud-ouest par une partie du lot 219-51 (rue).Cette partie de lot mesure deux cent soixante-quinze pieds (275') et cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et vingt-cinq pieds (25') dans sa ligne sud-ouest sur les lots 219-50 a 219-54 inclusivement, quatre mille cinq cent soixante-sept pieds et trois dixièmes de pied (4,567.3') dans sa ligne nord-est, trois cent soixante-seize pieds '376') dans sa ligne sud-est et quatre mille quatre cent, soixante-six pieds (4,466') dans sa ligne sud-ouest.Contenant en superficie 44.15 arpents carrés.northeast by the residue of lot 219, towards the southeast by the official cadastre for the Parish of Ste-Anne and towards the southwest by lot 220 and in another small southwest line by part of lot 219-51 (street).This part of lot measures two hundred and seventy-five feet (275') and one hundred feet (100') in its northwest line and twenty-five feet (25') in its southwest line on lots 219-50 to 219-54 inclusively, four thousand five hundred and sixty-seven feet and three tenths of a foot in its northeast line, three hundred and seventy-six feet (376') in its southeast line and four thousand four hundred and sixty-six feet (4,466') in its southwest line.Containing a superficial area of 44.15 square arpents.Les immeubles susdits sont tous du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève et situés dans la Ville de Pierrefonds.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné à Pierrefonds.ce 23e jour d'octobre 1973.Le greffier, 54362-44-2-0 Gabriel Legault.The above immovables are all on the official plan and in the book of reference of the Parish of Ste.Geneviève and situated in the City of Pierrefonds.The sail! sale will be marie with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at Pierrefonds, this 23rd day of October, 1973.Gabriel Legault, 54362-44-2-0 City Clerk.Ville de Pointe-Gatineau Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la ville de Pointe-Gatineau que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville de la susdite municipalité, 5, boul.du Progrès, MERCREDI le VINGT-HUITIÈME jour de NOVEMBRE 1973, à DIX heures l'avant-midi, pour satisfaife au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêt, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles en date du 26 septembre 1973.Town of Pointe-Gatineau Public notice is hereby given by the undersigned Town Clerk of Pointe-Gatineau that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of the above mentioned Municipality, 5 Blvd.du Progrès on WEDNESDAY, the TWENTY-EIGHTH day of NOVEMBER 1973, at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the 26th of September 1973.No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) Total Roll Owner's Xante Cadastral Aro.Munie, taxes School taxes JVo.(int.and costs) (interest) 7001115 Pointcolnc.588-233.7001212 Pointco Inc.588-240.7001213 Pointcolnc.588-241.7001349 Ménard Const.Ltée.588-305.7001350 Ménard Const.Ltée.588-306.7003110 Charles Glazer et of.566-34 7005301 Proulx, Gilbert.555-174.7006815 Provost, Jacques.557-50 7008130 Immeubles Tessier Ltée.571-54.7008131 Immeubles Tessier Ltée.571-48.7008132 Immeubles Tessier Ltée.571-47.7013407 Ladouceur.Ludger.518-2.7015629 Beaudin, Jean-Louis.572-56 7016306 Bergeron.Louis.253-7.7017405 Pilon, Real.238-10.7028104 McDermott, Léo.533-1.7021210 Gosselin, Richard.554-40.195.06\t8 8.45\t$ 203.51 581.56\t59.28\t640.84 138.82\t29.14\t167.96 392.02\t102.92\t494.94 433.89\t93.97\t527.86 794.04\t296.75\t1,090.79 1,043.43\t454.21\t1,497.64 998.49\t194.15\t1,192.64 186.64\t23.25\t209.89 146.32\t\t146.32 146.32\t\t146.32 1,093.24\t283.15\t1,376.39 1,594.74\t237.15\t1,831.89 793.68\t122.60\t916.28 545.57\t\t545.57 613.52\t93.55\t707.07 1,151.51\t272.75\t1,424.26 665S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November JO, 1973, Vol.105, No.1,5 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) Total Roll Owner's Name Cadastral No.M unie, taxes School taxes No.(int.and costs) (interest) 7025118 7014835 7016402 7036226 7036227 7042118 7042204 7042413 7042508 7042516 7042605 7042611 7047108 7047109 7047111 7047116 7047327 704732S 7047509 7047517 7047522 7047525 7047526 7047603 7048506 7006804 7016316 7003118 7(1031 19 7035721 7035820 7006201 Louis Lafl Dodaro, 488-3.\t531.99\t21.65\t553.64 118.\t1,476.09\t\t1,476.09 254 3.\t913.11\t109.30\t1,022.41 4-89.\t200.30\t61.68\t261.98 \t176.76\t61.38\t238.14 26-49.\t2,287.27\t32.85\t2,320.12 26-88.\t120.40\t20.15\t140.55 26-56.\t110.49\t19.55\t130.04 25-29.\t106.63\t23.15\t129.78 26-24.\t113.67\t22.00\t135.67 25-18.\t110.24\t19.55\t129.79 26-09.\t117.72\t\t117.72 33-54.\t104.43\t23.30\t127.73 33-55.\t107.81\t23.70\t131.51 33-57.\t107.81\t23.70\t131.51 33-62.\t2,675.84\t79.25\t2,755.09 34-32.\t117.88\t\t117.88 34-33.\t117.88\t\t117.88 34-53.\t104.76\t40.85\t181.61 34-74.\t119.59\t21.65\t141.24 34-60.\t114.08\t\t114.08 34-69.\t109.74\t\t109.74 34-68.\t153.98\t\t153.98 34-84.\t215.95\t167.23\t383.18 37-46.\t336.15\t116.91\t453.06 557-45.\t956.90\t360.54\t1,317.44 251-18.\t687.19\t183.25\t870.44 566-36.\t1,363.59\t136.42\t1,500.01 566-35.\t857.90\t44.51\t902.41 4-136.\t209.31\t73.78\t283.09 4-193.\t364.94\t49.49\t414.43 557-160 à/to 167,\t14,946.77\t1,868.20\t16,814.97 P.557\t\t\t Des lopins de terre situés à Pointe-Gatineau connus et désignés comme étant les lots numéros cent soixante-trois, cent soixante-quatre, cent soixante-cinq, cent soixante-six et cent soixante-sept de la subdivision du lot numéro cinq cent cinquante-sept (557-160, 161.162, 163, 164.165, 166.167) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Un lopin de terre connu et désigné comme étant partie du lot cinq cent cinquante-sept non subdivisée (ptie 557 n.s.) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; mesurant cent vingt pieds (120') dans ses lignes est et ouest; par deux cent trente-quatre pieds et cinq dixièmes (234.5') dans ses lignes nord et sud.mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit: au nord par le chemin de la Savane ou partie du lot 564; au sud par les lots 557-164.165.166, 167; à l'est par partie du lot 58-1; et à l'ouest par les lots 557-160.161 et partie du lot 557-162; avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau, Province of Québec, known as being lot number hundred sixty to hundred sixty-six (160 to 166) of the subdivision of the lot number 557 according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau.A piece of land known as being a part of the lot 557 non subdivised according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau; containing hundred twenty feet (120') to the east and west and two hundred thirty-four feet and five tenths of a foot (234.5') to the north and south.The whole English measure more or less; bounded to the north by Savane Street to the south by lots 557-164 to 557-167 to the east by part of the lot 58-1 and to the west by the lot 557-160, 557-161 and part of the lot 557-162.7006206 Graveline, Raoul.6! Un emplacement situé à Pointe-Gatineau, province de Québec, connu et désigné comme étant la subdivision non-officielle quatre cent quinze (415 n.o.) de la subdivision officielle un, de la resubdivision du lot originaire cinquante-huit (58-1) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, le tout tel que démontré sur un plan préparé par M.G.Rinfret, arpenteur-géomètre, en date du 25 octobre 1952, ledit lopin de terre mesurant quarante-huit pieds de largeur sur cent pieds de profondeur (48' x 100') mesures anglaises, plus ou moins et borné comme suit: au nord par la route de la Savane, au sud par la subdivision numéro 414.propriété de Nisphas Richer, à l'est par la subdivision 416, propriété de Nisphas Richer, ou représentants, et à l'ouest par une autre partie dudit lot cinquante-neuf propriété de Immeuble Gatineau Ltée ou représentants.l-(454) P.378.45 12.40 390.85 An emplacement situated in Town of Pointe-Gatineau-Province of Québec, known as being the non official subdivision (415 n.W.) of the official subdivision 1, of the resubdivision of the originally lot 58-1 according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau, containing forty-eight feet (48') to the north and south by hundred feet (100') to the east and west.The whole English measure more or less.This piece of land described is bounded to the north by Savane Street to the south by the subdivision number 414 to the east by the subdivision 414 and to the west by lot (557 n.s.). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6659 Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.KÔIe (int.et frais) (intérêt) Owner's Xame Cadastral Xo.Munie, taxes School taxes (int.and costs) (interest) 7006715 Menard Const, ltée.Un lopin de terre connu et désigné comme étant le lot numéro quatre cent vingt-six de la subdivision non-officielle du lot numéro un de la subdivision officielle du lot numéro cinquante-huit (58-1-426) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; aussi connu comme étant la subdivision quatre cent soixante-huit non-officielle (468 n.o.) du même cadastre; mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent cinq pieds (105') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; borné comme suit: au nord par le lot 58-1-425 propriété de M.Raymond Durant ou représentants; au sud par le lot 58-1-427 propriété de M.Aldége Corbeil ou représentants; à l'ouest par la rue Michaud; et à l'est par le lot 483 propriété de M.Pierre Charron ou représentants.7008817 Immeubles Tessier inc.571- Un terrain vague, connu et désigné, comme étant une partie du lot cinq cent soixante et onze n.s.aussi connu cemme étant le lot cinq cent soixante et onze (571-31 n.o.) dtmcntié sur un plan préparé par Marcel Ste-Marie.arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 1973.Borné à l'ouest par le lot cinq cent soixante et onze (571-32 n.o.), au nord par le lot rirq cent soixante et onze (571-30 n.o.) au sud par une lue projetée.7013210 Léonard, Jean-Léopold.557 La moitié indivise d'un lopin de terre connu et désigné comme étant partie du lot numéro cinq cent cinquante-sept non subdivisé (Ptie 557 n.s.) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, mesurant quarante-sept (47') dans sa ligne sud-est: quarante pieds (40') de largeur et cent trente-quatre pieds (134') dans ses lignes est et ouest, mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit: au nord par partie du même lot, propriété de Mme Wilson; au sud-est par la rue St-Louis; à l'est par partie du lot 557 n.s.et à l'ouest par le lot 552.7016338 Immeuble Tessier inc.67 LTn terrain vague connu et désigné comme étant une partie du lot cinq cent soixante et onze n.s.démontré sur un plan préparé par Marcel Ste-Marie.arpenteur-géemètre, contenant approximativement vingt-neuf milles cinq cent vingt-quatre pieds carrés, borné au sud par le lot deux cent quarante-deux (242-2), à l'ouest par la rue Marengère, à l'est par les lots deux cent cinquante et un (251-27 à 251-30) et au nord par le lot cinq cent soixante et onze n.s.58-l-(468) P.645.51 21.44 666.95 An emplacement situated in Town of Pointe-Gatineau, Province of Québec, known as being the lot number four hundred twenty-six of the non official subdivision of the lot number one of the official subdivision of the lot fifty-eight (58-1-426) according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau; also known as being the subdivision four hundred sixty-eight.(468) non official of the same cadastre; measuring fifty feet (50) width by hundred five feet (105) depth the all English measure more or less; bounded to the north by the lot fifty-eight (58-1-425) to the south by the lot fifty-eight (58-1-427) to the west by Michaud street and to the east by the lot four hundred eighty-three (483) non official.31 n.off.113.80 21.08 134.88 An emplacement known as being a part of the lot five hundred seventy-one, also known lot thirty-one of the n.o.subdivision five hundred seventy-one as shown on the plan prepared by Marcel Ste-Marie, Surveyor, dated from October 11.1973.Bounded to the west by lot five hundred seventy-one (571-32 n.o.), to the north by lot five hundred seventy-one (571-30 n.o.).to the south by a part of a street.P.377.07 18.50 395.57 An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known as being a part of the lot five hundred fifty-seven (557) non subdivised, according to the cadastre of Village of Pointe-Gatineau, measuring forty-seven feet (47') in his southwest line, forty feet (40') width and hundred thirty-four feet (134') in his line east and west, English measure more or less; bounded to the north by part of the same lot to the southwest by St-Louis street to the east by part of the lot five hundred fifty-seven (557) non subdivised and to the west by the lot five hundred fifty-two (552).IP.331.96 46.76 378.72 An emplacement known as being a part of lot five hundred seventy-one n.s., as shown on a plan prepared by Marcel Ste-Marie, Surveyor, containing approximately twenty-nine thousand and five hundred twenty-four square feet, bounded to the south by lot two hundred forty-two (242-2) to the west by Marengère street, to the east by the lots two hundred fifty-one (251-27 to 251-30) and to the north by the lot five hundred seventy-one n.s.7017317 Fleurant, Lionel Un lopin de terre connu et désigné étant partie des lots (pties 198, 199.200 et 201) au cadastre officiel du vil'age de Pointe-Gatineau, mesurant en tout quarante-cinq pieds (45') dans ces lignes nord et sud par quatre-vingt-trois pieds (83') dans ces lignes est et ouest, mesures anglaises et plus ou moins; borné comme suit: au nord par les dix pieds (10) nord dudit lot 198; au sud par les sept pieds (7') sud du lot 201; à l'est par les quinze pieds (15') est desdits lots 198, 199.200 et 201 et à l'ouest par partie du lot 579-15.198-P.A.76.36 6.20 82.55 201 P.An emplacement known as being a part of the lots (Pts 198, 199, 200 and 201) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, measuring forty-five feet (45') in his line north and south and eighty-three feet (83') in his line east and west.English measures more less; bounded to the north by the ten feet (10') north of the same lot 198; to the south by the seven feet (7') south of the lot 201; to the east by the fifteen feet (15') east of the lots 198 to 201 and west by part of the lot 579-15.7016431 Bigras, Simon.669 Un lopin de terre sis et situé à Pointe-Gatineau, connu et désigné comme étant partis du lot numéro cinq cent soixante-neuf (569-ptie) au cadastre du village de Pointe-Gatineau.mesurant quarante-cinq pieds (45') de largeur sur quatre-vingt-huit pieds (88') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et borné comme suit: Au nord par partie du même lot, propriété de C.Duval ou représentants; au sud par partie du même lot, propriété de Albert Galipeau ou représentants; a l'ouest par la rue Cousineau et à l'est par le lot numéro 568.p.426.86 S 159.09 $ 582.95 An emplacement situated in the town of Pointe-Gatineau.Province of Québec, known as being a part of the lot number 569 pt.according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, containing forty-five feet (45') to the east and west and eighty-eight feet (88') to the north and south.The whole English measure more or less.This peace of land is bounded as follows: to the north part of the same lot, to the south by part of the same lot to the west by Cousineau street and to the east by the lot 568. 6660 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.4-5 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) _ ^ ^ Poll Owner's Xame Cadastral No.Munie, taxes School taxes No.(int.and costs) (interest) Avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances et sujet à toutes servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes pouvant affecter ledit immeuble portant le numéro civique 113, rue Cousineau, â Pointe-Gatineau, province de Québec.7019525 Lamoureux et frères.480-1 P.1.Un lopin de terre, connu et désigné comme étant le lot numéro un de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-vingt (480-1) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; moins les emplacement déjà vendus par le présent vendeur a MM.Prançois-Xavier Lortie, Paul-Emile Lamoureux, Bernard Malette, Léo Yelle et al., Cie d'Habitation Ltée.Jacques St-Louis, Noël Lamoureux, Joseph ToutlorT et Lionel L'Ecuyer.259.88 36.72 296.60 2.Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances.Un lopin de terre, connu et désigné comme étant partie du lot numéro un de la subdivision du lot numéro quatre cent quatre-vingt-sept (487-1 ptie) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; étant tout le lot moins la partie vendue à Pointco Inc.1.An emplacement situated in the Town of Pointe-Gatineau, Province of Quebec, known as being the lot number one of the subdivision of the lot number four hundred eighty (480-1) according to the cadastre of toe town of Pointe-Gatineau; this property less the emplacements already sold to Misters François-Xavier Lortie, Paul-Emile Lamoureux, Bernard Malette, Léo Yelle, Cie d'Habitations Ltée.Jacques St-Louis, Noel Lamoureux, Joseph Touttlof and Lionel Lécuyer.2.An emplacement known as being a part of the lot number one of the subdivision of the lot number four hundred eighty-seven (487-1 Pt) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau containing all the lots less a part all ready sold to Pointco Inc.7023147 Philippe, Séguin, Irène.471 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro 4 de la subdivision du lot numéro (471 ptie 4) au cadastre du village de Pointe-Gatineau; mesurant cent dix pieds (110') au nord et cent huit pieds (108') au sud de largeur, par mille cinq cent soixante-cinq pieds (1,565') à l'ouest et mille cinq cent quatre-vingt-douze pieds (1,592') à l'est de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; le tout borné comme suit: au nord par partie du lot 470; à l'est par le lot 472-2; au sud par le cent cinquante pieds (150') sud, résidu du lot 471-4, propriété du vendeur et à l'ouest par le lot 464-4, propriété de M.Régent Séguin; le tout sujet a une servitude de la Commission Hydroélectrique du Québec et enregistré à Hull, sous le numéro 184-233.-4P.485.97 125.96 611.93 An emplacement known has being a part of the lot number 4 of the subdivision of the lot number (471 pt 4) according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau; measuring one hundred ten feet (110') to the north and one hundred eight feet (108') to the south by one thousand five hundred and sixty-five feet (1,565') to the west and one thousand five hundred and ninety-two feet (1,592') to the east, English measures more or less bounded to the north by a part of the lot 470; to the west by the lot 464-4; to the east by the lot 472-2; to the south by the one hundred fifty feet (150') south, balance of the lot 471-4.7047120 W.T.Shean.33-66 P.Un lopin de terre connu et désigné comme étant une partie du lot soixante-six (66) de la subdivision officielle du lot numéro trente-trois (33-66 ptie) de forme irrégulière mesurant dans sa ligne ouest cinquante-six pieds et cinq dixièmes (56.5') dans sa ligne nord-ouest soixante-dix pieds et deux dixièmes (70.2') dans sa ligne nord-est cent quatorze pieds et neuf dixièmes (114.9').dans sa ligne sud-est cinquante-cinq pieds et six dixièmes (55.6'), dans sa ligne sud cent pieds (100').Le tout en mesures anglaises plus ou moins; borné comme suit, au nord par la Route numéro 8, au nord-est par le lot trente-trois (33-67 ptie), au sud par le lot trente-trois (33-65) et à l'ouest par la rue St-Antoine.1,783.01 30.75 1,813.76 An emplacement known as being a part of the lot sixty-six of the official subdivision of the lot thirty-three (33-66Part) of irregular form measuring in its line west fifty-six feet and five tenths of a foot (56.5') in its line northwest seventy feet and two tenths of a foot (70.2') in is line northeast hundred fourteen feet and nine tenths of a foot (114.9') in its line southeast fifty-five feet and six tenths of a foot (55.6') in its line south hundred feet (100 ).The whole in English measure, more or less; bounded to the north by the Highway number 8, to the northeast by the lot thirty-three (33-67Part), to the south by the lot thirty-three (33-65) and to the west by St-Antoine street.7048409 Rideau State Inc.36-47 N.Off.93.74 2.55 96.29 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 47 selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre.le 1er juin 1959, de forme triangulaire, borné comme suit au nord par une rue projetée, â l'est par le lot 36-37 n.o., â l'ouest par le lot 35-48 n.s.An emplacement known as being a part of the lot 36 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official 47 as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959, of a triangular form bounded to the north bv a projected street to the east by the lot 36-37 n.o.and to the west by the lot 35-48 n.s.7049417 Rideau State Inc.36-28 A N.Off .Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau.aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 28A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, mesurant approximativement 37.5 de largeur 101.43 16.96 118.38 An emplacement known as being a part of the lot 36, according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision n.o.28-A as shown measuring an approximately to the 37.5 by 136 of depth, bounded to the north by the lot 36-27 n.o.to the east by a GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.n° 1,5 6661 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes scol.Rôle (int.et frais) (intérêt) Total null Owner's Xame Cadastral Xo.Munie, taxes School taxes \u2022Vo, (int.and costs) (interest) par 136' pieds de profondeur borné au nord par le lot 36-27 projected street, to the south by the lot 36-28B n.o.and to n.s., à l'est par un chemin projeté, au sud par le lot 36-28B the west by the lot 36-30 n.o.n.o., et à l'ouest par le lot 36-30 n.o.7048420 Rideau State Inc.3 I'n terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 du cadastre de Village de Pointe-Gatineau.aussi connu comme étant la subdivision non-officielle 50A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin i959.de forme irrégulière, borné au nord par une rue projetée, à l'est par le lot 36-50B n.o.et au sud par le lot 36-49 n.o.et à l'ouest par le lot 35-56 n.o.SO AN.Off.98.81 15.10 113.91 An emplacement known as being a part of the lot 36 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau.also known as being the subdivision non official 50A, as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor the 1st of June 1959.Irregular form bounded to the north by a projected street to the east by the lot 36-50B n.o.to the south by the lot 36-49 n.o.and to the west by the lot 35-56 n.o.7048426 Rideau State Inc.36- Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre du village de Pointe-Gatineau.aussi connu étant la subdivision non-officielle 51A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, de forme triangulaire, borné à l'est par le lot 36-51B n.s.au sud par un chemin projeté, a l'ouest par partie du lot 35-16 n.o.51 AN.Off.95.74 13.95 109.69 An emplacement known as being a part of the lot 36< according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau-also known as being the subdivision non official 51-A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959, of triangular form bounded to the east by the lot 36-51B, to the south by a projected street and to the west by a part of the lot 35-16 n.o.7048427 Rideau State Inc.3 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot trente-six (36) au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant la subdivision non-officielle cinquante-deux (52) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, de forme irréguiière, borné au nord par une rue projetée, à l'est par le lot trente-six (36-24) non officiel et au sud par le lot trente-six (36-51) non officiel et à l'ouest par le lot trente-cinq (35-15) non officiel.52 n.off.72.92 5.05 77.97 An emplacement known as being a part of the lot thirty-six (36) according to the cadastre of the Village of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official fifty-two (52) as shown on the plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary.Surveyor, the 1st of June 1959.of irregular form bounded to the north by a projected street, to the east by the lot thirty-six (30-24) non official, to the south by the lot thirty-six (36-51) non official, and to the west by the lot thirty-five (35-15) non official.7048428 Rideau State Inc.3 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot trente-six (36) au cadastre du village de Pointe-Gatineau.aussi connu comme étant la subdivision non officielle vingt-quatre (24A) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959, mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, borné comme suit au nord par une rue projetée, à l'est par le lot trente-six (36-24B) non officiel, au sud par le lot trente-six (36-25A) non officiel, et à l'ouest par le lot trente-six (36-52) non officiel.M An.off.124.61 334.56 459.17 An emplacement known as being a part of lot thirty-six (36) according to the Cadastre of the Village of Pointe-Gatineau.also known as being the subdivision non official twenty-four (24A) as shown on the plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary.Surveyor, the 1st of June 1959, measuring fifty-feet (50') width by hundred feet (100') depth bounded to the north by a projected street to the east by the lot thirty-six (36-24B) non official, to the south by the lot thirty-six (36-25A) non official, and to the west by the lot thirty-six (36-52) non official.7048603 Georges Alexopoulos.3 Un terrain connu et désigné comme étant partie du lot 36 au cadastre de la ville de Pointe-Gatineau aussi connu comme étant la subdivision non officielle 17A selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959; mesurant cinquante pieds (50') de largeur par cent pieds (100') de profondeur, borné au nord par le lot 36-16A et B.au sud par une rue projetée, à l'est par le lot 36-17B.Le tout, mesure anglaise, plus ou moins.17A n.o.137.88 137.88 An emplacement known as being a part of the lot 36, according to the cadastre of the Town of Pointe-Gatineau, also known as being the subdivision non official 17A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring fifty feet (50') of breadth and one hundred feet (100') of depth; bounded to the north by the lot 36-16A et B to the south by a projected street, to the east by the lot 36-17B the whole English measure more or less.7048608 Duval, René.3 Un certain terrain de forme rectangulaire faisant partie du lot trente-six aussi connu comme étant une partie du lot trente-six (36-18B Ptie n.o.) démontré dans un plan préparé par M.Jean-Paul Alary.1er juin 1959, borné au nord par la Route numéro 8, a l'est par le lot trente-six (36-16A n.o.).au sud par le lot trente-six (36-19A n.o.) et l'ouest pat une rue projetée.18Bn.off.343.61 7.90 351.51 An emplacement known as being a part of the lot thirty-six.also known as being lot thirty-six (36-18B part n.o.) as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, June 1st, 1959, bounded to the north by the Highway number 8, to the east by lot thirty-six (36-16A n.o.l, to the south by lot thirty-six (36-19A n.o.) and to the west by a projected street. 6662 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10.1973, Vol.105, No.45 No Nom des propriétaires No de cadastre Taxes munie.Taxes «col.Rôle (int.« f««) (intérêt) , Total Bail Oirnrr'f .Vome Cadastral No.Munie, taxes School taxes Yo.(inf.and costs) (interest) 7048612 Ride State Inc.35-2B n.off.1.456.00 430.20 1.886.20 Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 35 au cadastre du village de Pointe-Gatineau, aussi connu comme étant le lot 35-2B n.o., selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre le 1er juin 1959.mesurant cinquante pieds (50*) de largeur par cent vingt pieds (120') de profondeur, borné au nord par la route 8, à l'est par le lot 35-3 n.o.au sud par le lot 35-9 n.o., il l'ouest par le lot 35-2A.n.o.An emplacement known as being a part of the lot 35 according to the Cadastre of the Town of Pointe-Gatineau also known as being the lot 35-2B n.o., as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959, measuring fifty feet (50') of breadth and one hundred twenty feet (120/) of depth, bounded to the north by highway number 8.to the east by the lot 35-3 n.o.to the south by the lot 35-9 n.o.and to the west by the lot 35-2A n.o.7048614 Ayiscontoyannis.36-1A & B n.off.485 69 485.69 Un terrain vague connu et désigné comme étant partie du lot 35 du cadastre de la ville de Pointe-Gatineau aussi connu comme étant le lot 35-1A et B ptie et ptie 35-2A.35-10A et B.35-9A (n.o.) selon un plan préparé par M.Jean-Paul Alary, arpenteur-géomètre, le 1er juin 1959; borné au nord par la route No 8, à l'est par le lot 3S-9B n.o.et 35-2B n.o., au sud par la rue projetée et à l'ouest par la limite du lot 34.An emplacement known as being a part of the lot 35, also known as being the subdivision non official 35-1A et B part, 35-2A pt.35-10A and B, 35-9A as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, on the let of June 1969; bounded to the north by the highway No.8, to the east by the lot 35-2B n.o.and 35-9B n.o.to the south by a projected street and to the west by the limit of the lot 34.7048704 Gaston Yaliquette 36-5B n.off.124.79 124.79 Un certain terrain de forme rectangulaire ou carré faisant partie du lot (p, 30) selon les plans et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau.division d'enregistrement de Hull, décrit comme suit: Commençant à un point sur la ligne est du lot 36 situé à une distance de mille quatre-vingt-treize pieds et un dixième (1.093.1') au sud de l'intersection de la ligne sud-est, du Chemin public (Route numéro 8) avec ladite ligne est du lot 36, ce point étant appelé le point de départ: de là, allant vers le sud, longeant la ligne est dudit lot 36.une distance de cent pieds (100') de là.vers le nord, à angle droit, une distance de cent pieds (100'); de là.vers l'est, à angle droit, une distance de cent pieds (100') jusqu'au point de départ.Ce terrain est borné comme suit: au nord et au sud par d'autres parties du lot 36; à l'ouest par une partie du lot 36 réservé par une rue.à l'est par le lot 37.Contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000' carrés) le tout en mesure anglaise, et aussi connu étant le lot numéro .', - A - et II de la subdivision n.o.du lot numéro (36-6AB n.o.).7048707 Lamouillere, Francis.36-8 A & B n.o.An emplacement known as being a part of the lot 36.also known as being the lot 36-5A et B n.o., as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring approximately the subdivision of one hundred feet (100') of breadth and one hundred feet (100') of depth; bounded to the north by the lot 36-6A & B n.o.to the south by the lot 36-4A & B, to the east by the lot 37-12 to 14 and to tho west by a projected street.Un certain terrain de forme carrée faisant partie du lot (P.36) selon les plan et livre de renvoi du cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau division d'enregistrement de Hull, décrit comme suit: Commençant à un point sur la ligne est du lot 36 situé à une distance de sept cent quatre-vingt-treize pieds et un dixième (793.1) au sud de l'intersection de la ligne sud-est du Chemin public (Route numéro 8) avec ladite ligne est du lot 36, ce point étant appelé le point de départ : de là, allant vers le sud.longeant la ligne est dudit lot 36, une distance de cent pieds (100') de là, vers l'ouest à angle droit, une distance de cent pieds (100') de là.vers le nord, à un angle droit, une distance de cent pieds (100') de là.vers l'est à un angle droit, une distance de cent pieds (100') jusqu'au point de départ.Ce terrain est borné comme suit: au nord et au sud par d'autres parties du lot 36; à l'ouest par une partie du lot 36 réservé pour une rue: à l'est par le lot 37.Contenant une superficie de dix mille pieds carrés (10,000' carrés).Le tout en mesure anglaise.180.89 180.89 An emplacement known as being a part of the lot 36, also known as being the lot 36-8A & B n.o.as shown on a plan prepared by Mr.Jean-Paul Alary, surveyor, the 1st of June 1959; measuring one hundred feet (100') of breadth and one hundred feet (100') of depth, bounded to the south by the lot 36-7A & B n.o.to the west by a projected street, to the north by the lot 36-9A & B n.o., to the east bv the lot 37-5 to 7.Donné à Pointe-Gatineau.P.Q., ce 25e jour du mois Given at Pointe-Gatineau, P.O., this 25th dav of d octobre 19(3.October 1973._ , Le greffier.Loris Lamarche, o.m.a.74381 -44-2-0 Loris Lamarche, o.m.a.54381-44-2-o Town Clerk. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n' 45 6663 Ville d'Anjou Avis est par la présente donné, que le Conseil municipal, par une résolution en date du 24e jour d'octobre 1973, a ordonné au soussigné, conformément à la Loi des cités et villes de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Ville d'Anjou, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville d'Anjou 7701, Ixiuis-Hippolyte Lafontaine, le VINGT-HUITIÈME jour de NOVEMBRE 1973.à DIX heures de l'avant-midi, heure normale de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales et scolaires, tant générales que spéciales de l'année 1972 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.Permission a été accordée par la Commission municipale de Québec pour autoriser une enumeration abrégée des numéros cadastraux.Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d'un an.du cadastre officiel de la Paroisse de l,ongue-Pointc, dans les limites de la Ville d'Anjou.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis de la Ville d'Anjou et à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale.City of Anjou Public notice is hereby given, that the City Council by a resolution dated October 24th 1973, has ordered the undersigned, persuant to the Cities and Towns act: to sell the immovables hereinunder described for nonpayment of taxation arrears owing to the corporation of the City of Anjou, with interest and cost, and that consequently the said immovables shall be sold by public auction in the Council room at the City Hall of Anjou, 7701, Louis-Hippolvte Lafontaine, City of Anjou, on the TWENTY-EIGHTH day of NOVEMBER 1973 at TEN o'clock in the forenoon, eastern standard time.However, there shall be excluded from the sale, the immovables on which municipal and school taxes, so general as special for the year 1972 and previous years shall have been paid prior to the sale.The Québec Municipal Commission has authorised the City of Anjou, an abriged form of cadastral numbers.Immovables hereafter described will be sold, subject to the one-year right of redemption, of official cadastie of Parish Longue-Pointe, within the limits of the City of Anjou.They shall be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if any, subject to all the acquired rights of the City of Anjou, and any servitudes both active and passive, apparent or un-apparent which may affect them.The purchase price of said immovables shall be payable immediately, in legal currency.Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes \u2014 Sale of immovables for non-payment of taxes Immeubles sujets au droit de retrait d'un an \u2014 Immovables subject to a right of redemption of one year (Les lots ci-après décrits sont du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou \u2014 The lots hereafter described arc of the official cadastre of the parish of Longue-Pointe in the limits of the City of Anjou).Folios Nom et adresse Xamc and address Description de l'immeuble Description of immovable 414-0090 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0091 Albert Forget, Jean Miron meaux.Montréal.414-0116 Sharand Construction Ltd., 414-0119 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0120 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0121 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0122 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0142 Sharand Construction Ltd., 414-0145 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.414-0167 Albeit Forget, Jean Miron, meaux, Montréal.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- , Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- a.'s Mrs.Foy.P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 414-211 414-212 414-261 414-278 414-279 414-280 414-281 414-405 414-433 414-172 m; ! QUÉBEC OFFICIAL CA7.ETTE.November 10.107.1.Vol.10Ô.\\n.43 Folios Nom et adresse Xamt and address Description de l'immeuble Description of immovable 414-0108 Albert Forget, Jean Miron, meaux, Montreal.414-0171 Marcel Picard et/and Mme/ therineest.Montréal.414-0180 Albert Forget.Jean Miron.meaux, Montréal.415-0238 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0239 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0240 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0254 Crémazie Investment Corp.415-0255 Crémuzie Investment Corp., 415-0257 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0258 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0259 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0261 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0262 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0263 Les Immeubles Anjou Ltée, 415 OL'liô Crémazie Investment Corp., 415-0266 Crémazie Investment Corp., 415-0267 Crémazie Investment Corp., 415-0268 Crémazie Investment Corp., 415-0303 Sharand Construction Ltd., 415-0310 Crémazie Investment Corp., 415-0311 Crémazie Investment Corp.415-0322 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0323 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0325 Crémazie Investment Corp., 415-0326 Crémazie Investment Corp., 415-0327 Crémazie Investment Corp.415-0328 Crémazie Investment Corp.416-0331 Crémazie Investment Corp.415-0332 Crémazie Investment Corp.416-0338 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0341 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0342 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0344 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0345 Sharand Construction Ltd.415-0348 Albert Forget, Jean Miron, meaux.Montréal.416-0373 Crémazie Investment Corp.415-0374 Crémazie Investment Corp., 415-0375 Crémazie Investment Corp.415-0376 Crémazie Investment Corp., 415-0392 Les Immeubles Anjou Ltée, 416-0393 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0394 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0395 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0401 Crémazie Investment Corp., 415-0402 Crémazie Investment Corp., 415-0403 Crémazie Investment Corp., 415-0404 Crémazie Investment Corp.416-0405 Crémazie Investment Corp., 415-0420 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0421 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0422 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0423 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0424 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0425 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0427 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0428 Les Immeubles Anjou Ltée, 415-0429 Les Immeubles Anjou Ltée.415-0477 Crémazie Investment Corp., 415-0478 Crémazie Investment Corp., 415-0479 Crémazie Investment Corp., 415-0480 Crémazie Investment Corp., 415-0485 Crémazie Investment Corp., 416-0486 Crémazie Investment Corp., 415-0488 Crémazie Investment Corp., 416-0489 Crémazie Investment.Corp., 415-0490 Crémazie Investment Corp., 415-0491 Crémazie Investment Corp., 415-0492 Crémazie Investment Corp , 415-0503 Crémazie Investment Corp., Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- Mrs.ft.Marchand, née/born Claire Picard, 11325, Ste-Ca- Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724.Désor- 7700 boul.Yves Prévost.Anjou.7700 boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montieal.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700.boul.Yves Prévost.Anjou., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal., Dominion Sq.bldg, apt 609.Montreal.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.a/s Mrs.Fov, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal Dominion Sq, Bldg, apt 509, Montreal., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost.Anjou.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.i Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montréal., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.i Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.7700, boul.Y'ves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Yves Prévost, Anjou.7700, boul.Y'ves Prévost.Anjou.a/s Mrs.Foy.P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724, Désor- , Dominion Dominion Dominion Dominion 7700.boul.7700, boul.7700.boul.7700, boul.Dominion Dominion Dominion Dominion Dorninion 7700, boul.7700, boul.7700.boni.7700, boul.7700, boul.7700.boul.7700, boul.7700, boul.7700, boul.Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Dominion Sq.Bldg.apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg.apt Yves Prévost Yves Prévost Yves Prévost Yves Prévost Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg.apt Yves Prévost Yves Prévost Yves Prévost Yves Prévost Y VOS Prévost, Yves Prévost, Yves Prévost Yves Prévost Yves Prévost Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, ant Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg, apt Sq.Bldg.apt Sq.Bldg.apt 509.Montreal 509.Montreal 509, Montréal.509.Montreal., Anjou., Anjou., Anjou., Anjou.509, Montreal.590, Montreal.509.Montreal 609.Montreal 509.Montreal., Anjou., Anjou., Anjou.Anjou.Anjou.Anjou., Anjou., Anjou., Anjou.509.Montreal 509, Montreal 509.Montreal.509, Montreal 509, Montreal.509, Montreal.509, Montreal.509, Montreal.509, Montreal.509, Montreal.509.Montreal.509.Montreal 414-473 414-487 414-505 415-46 415-47 415-48 415-62 415-63 415-65 415-66 415-67 415-69 415-70 415-71 415-73 415-74 415-75 415-76 415-111 415-118 415-119 415-130 415-131 415-133 415-134 415-135 415-136 415-139 415-140 415-146 415-149 415-150 415-152 415-153 415-156 415-181 415-182 416-183 415-184 415-200 415-201 415-202 415-203 415-209 415-210 415-211 415-212 415-213 415-228 415-229 415-230 415-231 415-232 415-233 415-235 415-236 415-237 415-285 415-286 415-287 415-288 415-293 415-294 415-296 415-297 415-298 415-299 415-300 415-311 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.10 novembre 1973.105- année, n' 45 666.5 Folios 415-0504 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-312 415-0505 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bide, apt 509, Montreal.415-313 415-0506 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bids, apt 509, Montreal.415-314 415-0507 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-315 415-0508 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 609, Montreal.415-316 415-0509 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509 Montreal.415-317 415-0510 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal 415-318 415-0512 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-320 415-0513 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal 415-321 415-0514 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-322 415-0515 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-323 415-0516 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-324 415-0517 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal 415-325 415-0528 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724.Désor- 415-336 meaux.Montreal.415-0542 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-350 415-0543 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-351 415-0544 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-352 415-0540 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 500, Montreal 415-357 415-0550 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-358 415-0551 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-359 415-0552 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-360 415-055.3 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-361 415-0554 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-362 415-0567 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-375 415-0568 Crétnazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-376 415-0569 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-377 415-0572 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal .415-380 415-0573 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-381 415-0574 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-382 415-0575 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509.Montreal.415-383 415-0605 Albert Forget, Jean Miron.Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724.Désor- 415-404 meaux, Montréal.415-0635 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509, Montreal.415-427 415-0636 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-428 415-0637 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.Le lot 415-429.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-429, to withdraw however the part used as a street.415-0639 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.Le lot 415-430, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-430.to withdraw however the part used as a street.415-0646 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.apt 509.Montreal.415-434 415-0649 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost.Anjou.415-437 415-0650 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.4.5-438 415-0651 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-439 415-0652 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost.Anjou.4i5-440 415-0653 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-441 415-0654 Les Immeubles Anjou Liée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.415-442 415-0657 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal .415-445 415-0658 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.415-446 415-0667 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg, apt 509, Montreal.Le lot 415-453, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-453, to withdraw however the part used as a street.415-0668 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Y'ves Prévost, Anjou.Le lot 415-454, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-454.to withdraw however the part used as a street.415-0670 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Y'ves Prévost, Anjou.Le lot 415-455.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-455, to withdraw however the part used as a street.415-0672 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-456, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-456, to withdraw however the part used as a street.415-0674 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-457, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-457, to withdraw however the part used as a street.415-0676 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Y'ves Prévost.Anjou.Le lot 415-458, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-458, to withdraw however the part used as a street.415-0678 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost.Anjou.Le lot 415-459, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-459, to withdraw however the part used as a street. 6666 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Nom et adresse Description de l'immeuble Name and address Description of immovable 415-0680 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-460, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-460.to withdraw however the part used as a street.415-0682 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-461, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-461, to withdraw however the part used as a street.415-0684 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700.boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-462, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-462, to withdraw however the part used as a street.415-0686 Les Immeubles Anjou Ltée.7700.boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-463, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-463.to withdraw however the part used as a street.415-0688 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost, Anjou.Le lot 415-464, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-464, to withdraw however the part used as a street.415-0690 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Y'ves Prévost.Anjou.Le lot 415-465.à distraire toutefois la partie servant, de rue.Lot 415-465.to withdraw however the part used as a street.415-0692 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Y'ves Prévost, Anjou.Le lot 415-466.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-466, to withdraw however the part used as a street.415-0694 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Y'ves Prévost, Anjou.Le lot 415-467, a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-467, to withdraw however the part used as a street.417-0060 Epinette Construction, 4275 Kent Ave., Montréal.417-52 417-0061 Epinette Construction, 4275 Kent Ave., Montréal.417-53 417-0210 Epinette Const.Corp., 4275.Kent Ave, Montreal.417-197 417-0218 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-205 417-0219 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy.P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-206 417-0235 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724.Désor- 417-222 meaux, Montréal.417-0237 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-224 meaux, Montréal.417-0238 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-225 meaux, Montréal.417-0239 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-226 meaux, Montréal.417-0252 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy.P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-239 417-0253 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-240 417-0285 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-272 417-0286 Sharand Const.Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-273 417-0297 Gary Ball.6655.Côte des Neiges, Room/Chambre 240, Montreal.417-284 417-0298 Gary Ball, 6655.Côte des Neiges, Room/Chambre 240, Montreal.417-285 417-0299 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-286 meaux, Montréal.417-0300 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-287 meaux.Montréal.417-0301 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-288 meaux, Montréal.417-0361 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-348 meaux, Montréal.417-0362 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-349 meaux, Montréal.417-0370 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-357 417-0372 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-359 417-0396 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-383 meaux, Montréal.417-0404 Sharand Construction Ltd.a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-391 417-0405 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425.Snowdon St., Montreal.417-392 417-0426 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs.Foy, P.O.Box 425, Snowdon St., Montreal.417-413 417-0429 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-416 meaux, Montréal.417-0430 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-417 meaux, Montréal.417-0558 Epinette Const.Corp., 4275, Kent Ave., Montreal.417-545 417-0559 Albert Forget, Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-546 meaux, Montréal.417-0560 Albert Forget, Jean Miron, Charlemugne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-547 meaux, Montréal.417-0561 Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-548 meaux, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE Dl QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.,,' 1,5 6fi67 Folios Nom et adresse Vmm and address Description de l'immeuble Description of immnrablc 417-0562 Gary Bail.6655.Côte des Neiges.Chambre/Room 240.Montréal.417-549 417-0568 Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge, Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-555 meaux.Montréal.417-0569 Albert Forget.Jean Miron.Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier.2724, Désor- 417-556 meaux, Montréal.417-0570 Albert Forget.Jean Miron, Charlemagne St-Onge.Anthime Trépanier, 2724, Désor- 417-557 meaux, Montréal.417-0574 Gary Bail.6655.Côte des Neiges.Chambre/Room 240, Montréal.417-561 515-0164 Romano Bartoloméo, 2870, Paradis, Montréal.418-78 418-81 5-0036 Giovanni Const.Ltée.10220, Esplanade, Montréal.418-120 418-121 418-122 515-0240 Giovanni Const.Ltée, 10220.Esplanade.Montréal.418-123 515-0720 Epinette Const.Corp.4275 Kent Ave., Montréal.Le lot 418-335.h distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 418-335.to withdraw however the part used as a street.395-0260 Claude Dufour.7499.Rhéaume.Anjou.Le lot 419-238 et une partie du lot 419-237 mesurant cette Loi 419-238 and a part of lot 419-237.measuiiiig this said dite partie 15.2 pieds de largeur par 70 pieds de profondeur et part 15.2 feet in width by 70 feet in depth and containing contenant une superficie de 1.064 pieds carrés, mesure anglaise an area of 1.064 square feet.English measure and more or et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par le less, and bounded as follows, to wit: on the north by lot lot 419-238, au sud par le lot 419-408, à l'ouest par la rue 419-238, on the south by lot 419-408, on the west by Rhéaume Rhéaume (419-244) et a l'est par une partie du lot 419-349.street, (419-244) and on the east by a part of lot 419-349.295-0436 Harry Fl.uider.8075.Lafontaine, Montréal.419-353 295-0802 Les Bonnes Entreprises Inc., 5405, Queen Mary Road, Montréal.419-411 295-0810 Century Holdings Ltd., 5465 Queen Mary Road, Montréal.419-413 5-0121 Clément Proulx, 8795, Alexandre, Anjou.420-240 420-241-1 270-0546 Guy Lébeillé.6986, Guy.Anjou.420-377-2 270-0554 Claude Sanschagrin, 2130, rue Fleury, Montréal.420-379 345-0014 Roger Colas, 56.Maplewood.Outremont.Montréal .420-497 345-0360 Roger Colas.56, Maplewood, Outremont.Montréal.420-561 345-0364 Roger Colas.56.Maplewood, Outremont.Montréal.420-562 345-0368 Roger Colas, 56.Maplewood.Outremont.Montréal.420 503 270-0582 Roger Colas, 56.Maplewood, Outremont, Montréal.420-564 270-0586 Roger Colas, 56.Maplewood.Outremont.Montréal.420-565 270-0590 Roger Colas.56.Maplewood.Outremont.Montréal.420-566 270-0594 Roger Colas, 56, Maplewood.Outremont, Montréal.420-567 345-0372 Roger Colas, 56.Maplewood, Outremont, Montréal.420-668 345-0436 Moroy Inc., 2033, Belgrade, Montréal.420-600 025-0198 Les Immeubles Reno Inc.& Dev.Versailles Inc., 7711.Curé Clermont, Anjou.Le lot 423-121, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-121.to withdraw however the part used as a street.025-0206 Les Immeubles Reno Inc.& Dev.Versailles Inc., 7711, Curé Clermont, Anjou .Le lot 423-122, a distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-122, to withdraw however the part used as a street.030-0712 Pierre Marchand.7451, Baldwin.Anjou.a) Cm partie du lot 423-195 mesurant cettedite partie 15 (a) A part of lot 423-195 measuring this said part 15 feet pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une in width by 67 feel in depth and containing an area of 1,005 superficie de 1.005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou square feet, English measure and more or less and bounded moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par une autre as follows, to wit: on the north by another part of said lot partie dudit lot 423-195.au sud par une partie du lot 423-196.423-195.on the south by a part of lot 423-196.as described décrite ci-dessous b).à l'ouest par une autre partie dudit lot below in (6), on the west by another part of said 423-195.and 423-195 et a l'est par une partie du lot 423-219 décrite ci- on the east by a part of lot 423-219 as described below in (d).dessous d).6) Le lot 423-196, à distraire toutefois la partie expropriée.(6) Lot 423-196, to withdraw however the expropriated part.c) Une partie du lot 423-197, mesurant cettedite partie 15 (c) A part of lot 423-197, measuring this said part 15 feet pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une in width by 67 feet in depth and containing an area of 1005 superficie de 1.005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou square feet.English measure and more or less and bounded moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-196.as du lot 423-196 décrite ci-haut a), au sud par une partie du lot above described in (a), on the south by a part of lot 423-197-1.423-197-1.à l'ouest par le résidu dudit lot 423-197.et à l'est on the west by the residue of said lot 423-197 and on the east par une partie du lot 423-219 décrite ci-dessous d).by a part of lot 423-219, as described below in (d).d) Une partie du lot 423-219 mesurant cettedite partie 60 (if) A part of lot 423-219.measuring this said part 60 feet pieds le long arrière des parties de lots ci-haut mis en vente along the rear of parts of lots as described above to be sold by par 5 pieds de profondeur et contenant une superficie de 5 feet in depth and containing an area of 300 square feet 300 pieds carré», mesure anglaise et plus ou moins et bornée English measure and more or less and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord, au sud et à l'est par d'autres wit: on the north, on the south and on the east by other parts parties dudit lot 423-219 et à l'ouest par une partie du lot of said lot 423-219 and on the west, by a part of lot 423-195 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10.1973.Vol.105.No.45 V olios Nom et adresse Xame and address Description de l'immeuble Description of immovable 423-195 décrite ci-haut a), par une partie du lot 423-190 décrite ci-haut 6) et par une partie du lot 423-197 décrite ci-haut c).030-2232 Frank Dingle, 7022.Baldwin.Anjou.a) Une partie du lot 423-305 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-304.au sud par une partie du lot 423-306 décrite ci-dessous 6).à l'ouest par des parties des lots 424-491-19 et 424-491-18 et à l'est par le résidu dudit lot 423-305.b) Une partie du lot 423-306, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant, une superficie de 2,160 pieds carrés et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-305.ci-dessus décrite a), au sud par une partie du lot 423-307.à l'ouest par des parties des lots 424-491-18 et 424-491-17 et a l'est par le résidu dudit lot 423-300.030-1000 Frank Dingle.7022.Baldwin.Anjou.a) Une partie du lot 423-307.mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-306.au sud par une partie du lot 423-308.ci-dessous décrite b).a l'ouest par des parties des lots 424-491-17 et 424-491-16 et h l'est par le résidu dudit lot 423-307.6) Une partie du lot 423-308, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-307.ci-haut décrite o), au sud par une partie du lot 423-309.a l'ouest par des parties des lots 424-491-16 et 424-491-15 et à l'est par le résidu dudit lot 423-308.as described above in (a), by a part of lot 423-196, as described above in (6).and by a part of lot 423-197, as described above in (c).(a) A part of lot 423-305, measuring this said part 30 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 2.160 square feet.English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-304, on the «outh bv a part of lot 423-306.as described below in (5).on the west by parts of lots 424-491-19 and 424-491-18 and on the east by the residue of said lot 423-305.(6) A part of lot 423-306 measuring this said part 30 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 2,160 square feet and more or less and bounded as follows to wit: on the north bv a part of lot 423-305.as described above in (a), on the south bv a part of lot 423-307, on the west by other parts of lots 424-491-18.and 424-491-17 and on the east by the residue of said lot 423-306.(a) A part of lot 423-307.measuring this said part 30 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 2.160 square feet.English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-306, on the south bv a part of lot 423-308, as described below in (6), on the west by parts of lots 424-491-17 and 424-491-16 and on the east, by the residue of said lot 423-307.(b) A part of lot 423-308.measuring this said part 30 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 2,160 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-307.as described above in (o).on the south by a part of lot 423-309.on the west by parts of lots 424-491-16 and 424-491-15.and on the east by the residue of said lot 423-308.025-1028 M.Mme.'Mr.Mrs Edgar Pilotte, née/born Armande Bergeron, 6994.Azilda, Anjou.o) Une partie du lot 423-380, mesurant cettedite partie 15 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 1,005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une autre partie dudit lot 423-380, au sud par une partie du lot 423-381, ci-dessous décrite b).à l'ouest par le lot 423-365 (ruelle) et a l'est par le résidu dudit lot 423-380-2.b) Une partie du lot 423-381, mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-380.ci-dessus décrite a), au sud par une partie du lot 423-382, a l'ouest, par le lot 423-365 (ruelle) et a l'est par le résidu du lot 423-381.025-1108 (a) A part of lot 423-380 measuring this said part 15 feet in width by 67 feet in depth and containing an area of 1,005 square feet, English measure and more or iess and bounded as follows, to wit: on the north by another part of said lot 423-380, on the south by a part of lot 423-3S1.as descril>ed below in (d), on the west by lot 423-365 (lane) and on the cast by the residue of said lot 423-380-2.(6) A part of lot 423-381 measuring this said part 30 feet in width by 67 feet in depth, and containing an area of 2.010 square feet.English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-380, as described above in (at.on the south by a part of lot 423-382.on the west by lot 423-305.(lane) and on the east, bv the residue of said lot 423-381.Succession Boudreau.Michel.Kobert.Lise, Jacques, Louis, André, Madeleine, Hélène Boudreau, 6938, Azilda, Anjou.Le lot 423-390, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-390, to withdraw however the part used as a street.025-1114 Mme we/Mrs.widow Alban Boudreau, née/born Aline Deraspe.6930, Azilda, Anjou Le lot 423-391, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-391, to withdraw however the part used as a street.030-1600 Mme/Mrs B.Léon Lecker.née/born Sarah Schw a) Une partie du lot 423-463.mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par une partie du lot 423-462.au sud par une partie du lot 423-464.décrite ci-dessous b).à l'ouest par le lot 424-467-5 et à l'est par le résidu dudit lot 424-463.b) Une partie du lot 423-464, mesurant cettedite partie 15 pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une sujwrficie de 1,080 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par une partie artz.1600.rue Dutrisac.St-Laurent.(a) A part of lot 423-463 measuring this said part 30 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 2,160 square feet English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north bv a par\" of lot 423-462, on the south by a part of lot 423-464 as described below in (6), on the west by lot 424-467-5 and on the east, bv the residue of said lot 424-463.(Ii) A part of lot 423-464.measuring this said part 15 feet in width by 72 feet in depth and containing an area of 1,080 square feet English mexsure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-463, as GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973.105' année.n° 1,5 6669 Folios Nom et adresse Xamc and address Description de l'immeuble Description of immovable du lot 423-463.décrite ci-haut (a), au sud et à l'est, par d'autres parties dudit lot 423-464 et a l'ouest par des parties des lots 424-467-4 et 424-467-5.described above in (a), on the south and on the east, by other parts of said lot 423-464 and on the west bv parts of lots 424-467-4 and 424-467-5.030-2066 Mme/Mrs Walter Bardo.née/born Stella Cvbulko.7767, Baldwin.Anjou 510-0116 Maurice Gendron.5663, Roi René, Anjou.520-0028 Giulio Stromei.5701.St-Donat, Anjou.Le lot 424-201 et une partie du lot 424-200 de forme irréguiière et contenant une superficie de 52 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par le lot 424-208.au sud.par le lot 424-194.à l'ouest par l'autre partie dudit lot 424-200 et à l'est par le lot 424-201.423-710 424-124-2 Lot 424-201 and a part of lot 424-200, of irregular shape and containing an area of 52 square feet English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north, by lot 424-208, on the south by lot 424-194, on the west by the other part of said lot 424-200 and on the east by lot 424-201.580-0101 R G V Inc., 5850, Bergevin.Brossard.Québec.424-232 520-0116 Raymond Ferland, 1867, Place Beauchesne.Montréal.424-257-2 510-0308 Pierre Poirier, 130, Cologne, Vimont.Laval.424-467-2 510-0324 Broadway Properties Ltd.6402.Sherbrooke ouest.Montréal.424-467-6 365-0030 Les Entreprises Tour Bellevue.5490.Henri Bourassa, Montréal.424-655 510-0482 Mlle Lvette L'Allier, 6285.Bover, Montréal.424-763 510-0486 Mlle Lyette L'Allier, 6285, Bover, Montréal.424-764 510-0498 Mlle Lyette L'Allier, 6285, Bover.Montréal.424-766 360-0144 M.Mme.'Mr.Mrs R.Poole Richards, née/born Patricia Hedgman, 8433, Peterborough 424-904 Circle, Anjou.190-0020 Roland Prairie.7627.De Fougerav, Anjou.424-912 105-0012 .1.Claude Gratton, 8425.Chàteauneuf.Anjou.424-936 370-0032 Dominique Paquette, 7751, Place Pigeon.Anjou.424-1001 120-0108 Jean-Paul Mongeau, 8337, Chénier.Anjou.426-113 200-0218 Mme Edward Williams, née/born Hazel Jackson, 7061, De La Loire.Anjou.426-316 200-0242 Emile Verreault.7201.De La Loire.Anjou.426-333 235-0140 Mme vve/Mrs.widow Alfredo Pansieri.née/born Irma Rossini.Angelo Pansieri.Dante 426-484 Pansieri.8340, Du Chardonnet.Anjou.200-0418 André Bouchard, 7861.De La Loire.Anjou.400-0002 Immeubles Versailles Inc.Immeubles Reno Inc Une partie du lot originaire 427, contenant une superficie de 40.508 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, parle boul.Métropolitain, par les lots 427-679 et 427-685 et par les parties des lots 427-678, 427-684 et 427-689.au sud, par la rue Roche-sur-Von.(427-956 et 427-957).à l'ouest par la ligne separative des terres 427 et 429 et à l'est par des parties des lots 427-689 et 427-1045.7711, Curé Clermont.Anjou.A part of original lot 427.containing an area of 40.508 square feet English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by Métropolitain Blvd.by lots 427-679 and 427-685 and by parts of lots 427-678, 427-684 and 427-689.on the south, by Roche-sur-Yon street (427-956 and 427-957), on the west, bv the separative line of farms 427 and 429 and on the east by parts of lots 427-689 and 427-1045.555-0048 280-0216 J.René Corneillier.8282, Talcy.Anjou.Roger Colas, 56, Maplewood, Outremont, Montréal.280-0220 Roger Colas, 56, Maplewood, Outremont, Montreal 175-0004 240-0276 280-0212 230-0144 561-0196 561-0200 070-0064 105-0360 203-0104 288-0120 523-0078 523-0082 177-0044 177-0048 523-0086 523-0090 181-0032 181-0040 523-0094 523 -0098 523-0102 523-0106 224-0132 André Archambault, 8080.Dalkeith.Anjou.Fabrique Notre-Dame d'Anjou.8200.Chénier, Anjou.Roger Colas, 56, Maplewood, Outremont, Montréal.Mme/Mrs.Rosaire Girard, née'born Louise Desforges.7841.Des Vendéens, Anjou.Jack Ilovitch, Abrahamb Braunstein, Moe Kogler, 5720, boul.Cavendish, Montréal.Jack Ilovitch, Abrahamb Braunstein.Moe Kogler, 5720, boul.Cavendish.Montréal Jacques Huard, 6334, Cairns, Anjou.Jack Rosenthal, Guy Meunier, 83, Jeffrey, Dollard Desormeaux.Claude Larouche, 6283.De La Mayenne.Anjou.Jean Perreault.6072, Galeries D'Anjou.Anjou.Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140, Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140.Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140.Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140, Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140.Gérard Dagenais Const.Ltd.2140, Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140.Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140.Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140, Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140, Gérard Dagenais Const.Ltd., 2140, Gérard Dagenais Const.Ltd.2140, MM.Pierre Fournier, André Gorvaj Champfleury, Duvernay .Champfleury, Duvernay.Champfleury, Duvernay.Champfleury, Duvernay.Champfleury.Duvernay.Champfleury.Duvernay.Champfleury, Duvernay.Champfleury, Duvernay.Champfleury.Duvernay.Champfleury, Duvernay.Champfleury, Duvernay Champfleury.Duvernay.s, 6070, Des Jalesnes, Anjou 427-931 427-1043 429-1700 427-1044 429-1699 429-1324 429-1401 429-1701 431-80 431-462 431-463 434-194 434-342 437-281 440-1260-6 440-1261-6 440-1292 440-1293 440-1304 440-1305 440-1306 440-1307 440-1315 440-1317 440-1329 440-1330 440- 1341 440-1342 440-1384 441-134 6670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1973.Vol.105.No.45 Folios Nom et adresse Xante and address Description de l'immeuble Description of immovable 445-0012 East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Mi-chel, Montréal.Une partie du lot originaire 445, mesurant cettedite partie 80.61 pieds de largeur par 210.87 pieds de profondeur et contenant une superficie de 16,998 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par le lot 445-33, au sud, par la rue Jarry (445-P).à l'ouest, par le Chemin de la Savane, et à l'est par la rue Des Ponts De Cé (445-32).East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty.8680, lOème Avenue, St-Mi-chel.Montréal.0 .East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOcme Avenue, bt-Mi-chcl.Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Mi-chel, Montréal.East End Development Corp., a/s Gilles Foisy, 9999, Hamelin.Montréal.East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Mi- chel, Montréal.\u201e East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOcme Avenue, St Michel.Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Mi-chel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOéme Avenue, St-Mi-chel, Montréal._ .East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue.St-Mi-chel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty.8680.lOème Avenue, St-Mi-chel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8080, lOème Avenue, St-Mi-chel, Montréal.East End Development Corp., a/s Monette Ouellette, 3482, Bélanger est, Montréal.102-0064 102-0068 102-0076 102-0212 102-0136 102-0092 102-0088 102-0084 102-OOSO 102-0100 129-0100 \\ part of original, lot 445.measuring this said part 80.61 feet in width by 210.87 feet in depth and containing an area of 16.998 square feet English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by lot 445-33, on the south, bv Jarry street (445-P).on the west, by De La Savane road and on the east, by Des Ponts De Ce Street, (445-32).445-25 445-26 455-19 445-28 445-38 454-1 455-U 459-23 455-15 455-16 455-17 455-18 455-22 462-36 463-77 288-0780 L & A Development Inc., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.Une partie du lot 463-15, mesurant cettedite partie, 25 pieds de largeur par 90 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,250 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par le lot 463-16 au sud, par le résidu dudit lot 463-15, à l'ouest, par le lot 463-37 et à l'est par le boul.Les Galeries D'Anjou (466-P.).A part of lot 463-15, measuring this said part, 25 feet in width by 90 feet in depth and containing an area of 2,250 square feet English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north, by lot 463-16, on the south, by the residue of said lot 463-15, on the west, by lot 463-37 and on the east, by Les Galeries D'Anjou Blvd.(466-P).288-0296 288-0300 288-0304 288-0308 288-0312 288-0316 288-0320 288-0324 288-0328 033-0236 033-0240 288-0880 288-0884 468-0016 471-0021 575-0120 East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty.8680.lOème Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOéme Avenue, St Michel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOeme Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp.a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOcme Avenue, St-Michel, Montréal.East End Development Corp., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOeme Avenue, St-Michel, Montréal.L & A Development Inc., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.L & A Development Inc., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.L & A Development Inc., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOcme Avenue, St-Michel, Montréal.L & A Development Inc., a/s Beam Montreal Realty, 8680, lOème Avenue, St-Michel, Montréal.Mme/Mrs.Lucien Hébert, née/born Rollande Couture, 446 Queens, St-Lambert, Québec.Fernando Bigue, 8611 D'AlIonnes, Anjou.Françoise Verreault, 3210, Forest Hill, app.1706, Montréal.'.'.463-16 463-17 463-18 463-19 463-20 463-21 463-22 463-23 463-24 463-99 463-100 463-101 463-102 467-28 468-33 471-49 473-97 475-64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6671 Folios Nom et adresse -Yam* and address Description de l'immeuble Description of immovable 186-0012 M.Mme/Mr.Mrs.Marcel Lessard, née/born Thérèse Beaulieu.9063.De Bretagne, Anjou 473-172 475-231 186-0024 Réal Pratte.9091, De Bretagne.Anjou.473-175 475-234 475-0136 Mlle Françoise Verreault, 3210, Forest Hill, app.1706, Montréal.475-111 211-0072 Mme/Mrs.Petro Kinach, née/born Maria Rebizant, 6136, Place Lacombe, St-Léonard.475-221 211-0076 Petro Klymchuk, 3195, Lacordaire, Montréal.475-222 477-0180 M.Mme/Mr.Mrs.Ferdinando Genevèse, née/born Maria Dominica Minotti, 8931, De 477-52 Louresse, Anjou.483-0013 Le Roseraie d'Anjou 1972 Inc., 7900, Grenache, Anjou.483-2 530-0100 CAPEQ Inc., 10700.Secant.Anjou.484-33 485-18 249-0068 Claude Aubin.7060, Azilda.Anjou.484-50 610-0017 MM.G.Gordon Sestock, Norman Sestock.10325, boul.St-Michel, Montréal-Nord.Une partie du lot 488-13.mesurant cettedite partie 195 A part of lot 488-13, measuring this said part 195 feet in pieds de largeur par 410.46 pieds de profondeur et contenant width by 410.46 feet in depth and containing an area of une superficie de 80,040 pieds carrés mesure anglaise et plus 80.040 square feet.English measure and more or less and ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord, par l'autre bounded as follows, to wit: on the north by the other part partie du lot 488-13, au sud par la rue Grenache (488-3).à of lot 488-13.on the south by Grenache street (488-3) on the l'ouest parle lot 487-7 et à l'est par le lot 488-10.west by lot 487-7 and on the east, by lot 488-16.615-0028 Midland Steel Ltd.8550, 3ème Avenue, Anjou.489-18 En foi de quoi, j'ai signé ce présent document, ce 24e jour d'octobre 1973.Le greffier.54382-44-2-0 Léonce Maltais, o.m.a.In testimony whereof, I have signed this present document, this 24th day of October 1973.Léonce Maltais, o.m.a., 54382-44-2-0 City-Clerk: Cité de Shawinigan Avis est par les présentes donné que les propriétés immobilières ci-dessous décrites seront vendues à l'enchère publique, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville avenue Des Cèdres, Shawinigan, MERCREDI, le DOUZIÈME jour de DÉCEMBRE 1973 à DEUX heures de l'après-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales, avec intérêts, plus les frais encourus ou qui pourraient être encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.City of Shawinigan Xotice is hereby given that the immovable properties described hereunder, situated in the City of Shawinigan, will be sold bv public auction in the council hall of the City of Shawinigan, on WEDXESDAY, the TWELFTH day of DECEMBER, 1973, at TWO o'clock of the afternoon, to satisfy the payment of the municipal taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before sale.Noms des propriétaires Xames of proprietors Cadastre Raymond Lafontaine.Pierre Deschênes.Auberge Cascade Limitée.Madame Léon Lamothe Léon Lamothe.Subdivision 028\t1692 62S\t445-15-1-1 028\t729-2 S28\t730-1 628\t576-1 628\t445-22 028\t1539 628\t1540 028\t1541 0,28\t445-21 0,28\t1528-1 028\t1527-1 027\t119 0,27\t94-1 027\t93-1 027\t95-1 usa\t156-4 6672 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Noms des propriétaires Xames of pro prie fors Cadastre Subdivision Roméo Noël.Bernard Beaulieu.Guy Trottier.Madame Juliette Bordeleau.Léo Auger.Origène Grenier.Charles Trottier.Réal Dessureault.44 44 44 44 44 44 32 32 47 30 48 55 66 66 17 P.16 P.19 17-1 18-2 17-2 18-1 8 9 1 53 73 r.P.8 4 Les propriétés immobilières susdites sont du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Flore et situées dans la Cité de Shawinigan.Donné à Shawinigan, ce 26e jour d'octobre 1973.Le greffier, 54498-45-2-0 Y von Boisvert.The above immovable properties are on the plan and in the hook of reference of the parish of Ste-Flore and situated in the City of Shawinigan.Given at Shawinigan, this 26th day of October, 1973.Y von Boisvert, 54498-45-2-0 City Clerk.Cite de LaSalle Avis public est, par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous décrites seront vendues à l'enchère publique en la salle du Conseil à l'hôtel de ville, dans la Cité de LaSalle, au No 13 avenue Strathvre.LUNDI, le DIX-SEPT DÉCEMBRE 1973, à ONZE hemes de l'avant-midi.pour satisfaire au paiement des taxes non-payées et les intérêts mentionnes dans l'état en plus des frais et intérêts qui ont été ou qui pourront être encourus à moins que lesdites taxes, intérêts et frais soient payés avant la vente.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives ou occultes, attachées auxdits immeubles.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Tous les immeubles vendus sont sujets au droit de retrait d'un an.City of LaSalle Public notice is hereby given that the properties described hereunder will be sold by Public Auction in the Council Meeting Hall at the City Hall, in the City of LaSalle.No.13 Strathyre Avenue, on MONDAY, the SEVENTEENTH day of DECEMBER, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon for unpaid taxes, interest and costs mentioned in the statement, in addition to the costs and interest which have been or may be incurred unless said taxes, interest and cost be paid sooner.The said sale will be made with all active and passive servitudes apparent or occult attached to the said properties.The purchase price of each of the said immoveables shall be payable immediately.All the immoveables sold are subject to the one-year right of redemption.\tNuméro du cadastre\tTaxes\tTaxes\tTaxe\tInt.\t Nom\tParoisse de Lachine\tmun.\tscol.\tspéc.\tet frais\t \t\t\t\t\t\tTotal .Va me\tCadastral number\tM un.\tSchool\tSpécial\tInt.and\t \tParish of Lachine\t(axes\ttaxes\ttax\tcosts\t \t1003/30 (avec bâtisse dessus érigée)\tS 303.05\t% 441.98\t$226.87\tS 71.42\t81,043.32 \t\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(2258-2260, rue Lapierre St.)\t\t\t\t\t \t996/1655 (avec bâtisse dessus érigée)\t453.31\t745.38\t422.65\t145.83\t1,767.17 \t\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(7708.rue George St.) 977/54 _ (avec bâtisse dessus érigée)\t338.65\t468.94\t242.05\t77.04\t1,126.68 \t\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(7789-7791, rue Chouinard St.)\t\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6673 \tNuméro du cadastre\tTaxes\tTaxes\tTaxe\tInt.\t Nom\tParoisse de Lachine\tmun.\tscol.\tspéc.\tet frais\t \t\t\t\t\t\tTotal -Yame\tCadastral number\tA/un.\tSchool\tSpecial\tInt.and\t \tPariah of Lachine\ttaxes\ttaxes\ttax\tcosts\t \t978/103 *\t265.52\t343.88\t417.66\t64.35\t1,091.41 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(1358-1360, rue Maurice St.)\t\t\t\t\t \t985/15\t113.89\t191.10\t108.19\t20.24\t433.42 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(8819, boul.LaSalle Blvd.)\t\t\t\t\t \t957/73\t104.41\t431.20\t128.58\t53.79\t717.98 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(156, rue Stinson St.)\t\t\t\t\t \t978/315\t293.25\t425.67\t242.33\t46.58\t1,007.83 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(7952-7954.rue Robert St.)\t\t\t\t\t Joly.M ./Mr & Mme/Mrs.Gérard\t961/527\t347.62\t453.74\t255.58\t51.13\t1,108.07 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(9352-9354, rue Eastman St.)\t\t\t\t\t Joly, M ./Mr.& Mme/Mrs.Gérard.\t974/67-6\t362.49\t664.44\t374.26\t68.16\t1.469.35 \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(9111-9113-9115.\t\t\t\t\t \tboul.LaSalle Blvd.)\t\t\t\t\t1,704.82 Joly, M ./Mr.& Mme/Mrs.Gérard .\t974/66-19, 69-13\t567.27\t677.18\t381.98\t78.39\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(9092-9094-9096-9098-9098A,\t\t\t\t\t \tterrasse Duquette Terrace)\t\t\t\t\t442.09 \t974/237\t\t401.80\t\t40.29\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(781-783.rue Maher St.)\t\t\t\t\t5.381.73 \t977/295\t2,412.54\t1,765.20\t762.97\t441.02\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(7722, boul.Newman Blvd.)\t\t\t\t\t1,258.83 \t974/918\t351.94\t506.66\t342.24\t57.99\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(1670-1672-1674,\t\t\t\t\t \tavenue Dollard Avenue)\t\t\t\t50.90\t1,106.79 \t969/39-2-2, 40-17-2, 40-18-1\t342.07\t431.20\t282.62\t\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(1015-1019, 90e-th Avenue)\t\t\t\t\t1,641.76 \t978/298\t464.38\t704.62\t396.89\t75.87\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(1426-1428-1430, rue Thierry St.)\t\t\t\t\t569.71 \t977/117-1, 296\t302.40\t141.50\t80.34\t45.47\t \t(non-construit/bldg.not erected)\t\t\t\t\t \t(1339-1341, rue Daigneault St.)\t\t\t\t37.50\t467.49 \t977/297\t248.09\t116.03\t65.87\t\t \t(non-construit/bldg.not erected)\t\t\t\t\t \t( 1335-1337, rue Daigneault St.)\t\t\t\t37.70\t469.69 \t977/298\t248.69\t116.93\t66.37\t\t \t(non-construit/bldg.not erected)\t\t\t\t\t \t(1331-1333, rue Daigneault St.)\t\t\t\t37.71\t469.84 \t977/299\t248.83\t116.93\t66.37\t\t \t(non-construit/bldg.not erected)\t\t\t\t\t \t(1327-1329, rue Daigneault St.)\t\t\t\t\t574.51 \t977/300\t304.04\t143.26\t81.34\t45.87\t \t(non-construit/bldg.not erected)\t\t\t\t\t \t(1323-1325, rue Daigneault St.)\t\t\t\t\t1,015.75 \t978/271\t293.89\t431.70\t243.16\t47.00\t \t(avec bâtisse dessus érigée)\t\t\t\t\t \t(with building thereon erected)\t\t\t\t\t \t(7987-7989, rue Fontaine St.)\t\t\t\t\t 6674 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.106, No.46 Nom Name Tomasic, Mihajlo.971/654 (avec bâtisse dessus érigée) (with building thereon erected) (2248-2250.rue Armel At.) 960/96-149 (avec bâtisse dessus érigée) (with building thereon erected) (189-191-191A, rue Clément St.) 974/899-2, 900-1 (avec bâtisse dessus érigée) (with building thereon erected) (7956-7958.rue Lefebvre St.) 959/156-1 (avec bâtisse dessus érigée) (with building thereon erected) (611-61 l-A-61 l-B-611-C, avenue Lafleur Avenue) 959/Pt.156 (avec bâtisse dessus érigée) (with building thereon erected) (607-609-609B, ave Lafleur Ave).959/Pt.156: Une certaine parcelle de terrain de figure régulière étant une partie du lot 959-156 du cadastre officiel de la paroisse de Lachine, division d'enregistrement de Montréal dans la Cité de LaSalle.Bornée au nord par le lot 959/156-1, â l'est par le lot 959-160-60, au sud par le lot 959-160-30, h l'ouest par une partie du lot 959 (Avenue Lafleur).Mesurant cent pieds (100.0') dans ses lignes nord et sud, cinquante pieds (50.0') dans ses lignes est et ouest.Contenant en superficie cinq mille pieds carrés (5,000 pi.car.), mesure anglaise.Le tout est tel qu'indiqué sur la copie du plan No.D.2552, référence 7310-021, en date du 11 octobre 1973 et préparé par l'arpenteur géomètre Jean-Paul Arsenault.Tremblay, M./Mr.& Mme/Mrs.Jacques.Zavaglia, Guiseppe.Zavys, Joseph et/and Susinskas, Viktoras.Zavys.Joseph et/and Susinskas, Viktoras.Numéro du cadastre Paroisse de Lachine Cadastral number Parish of Lachine Taxes mun.M un.taxes 351.56 245.42 664.82 Taxes scol.School taxes 478.24 330.63 113.74 806.08 574.66 Taxe spéc.Special lax 269.38 164.77 474.75 325.57 Int.et frais Int.and costs 53.21 150.71 8.96 173.90 120.99 Total 1,152.39 891.53 122.70 2,119.55 1,019.24 959/Pt.156: A certain parcel of land of regular figure, being part of lot 959-156 of the Official Cadastre for the Parish of Lachine.Registration Division of Montreal, in the City of LaSalle.Bounded to the north by lot 959-156-1.to the east by lot 959-160-60, to the south by lot 959-160-30.to the west by part of lot 959 (Lafleur Avenue).Measuring one hundred feet (100.0') in its north and south lines, fifty feet (50.0') in its east and west lines.Containing an area of five thousand square feet (5,000 sq.ft.), English measure.The whole is as shown on the copy of plan No.D.2552.reference 7310-021, dated October 11th, 1973 and prepared by Mr.Jean-Paul Arsenault, Québec Land Surveyor.Donné à LaSalle, ce 31e jour d'octobre 1973.Le greffier, 54499-45-2-0 Jacqueline Giguère-Boyek.Given at LaSalle, this 31st day of October 1973.Jacqueline Giguere-Boyeh, 54499-45-2-0 City Clerk.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications Abraham Kirschenzaft Avis est donné par les présentes que Abraham Kirsh-chenzaft.Gérant Assistant, domicilié à 2685 Kent Avenue, Apartement 402, dans la Ville de Montréal, district de Montréal, a l'intention de présenter une demande au ministre de la justice, en vue d'obtenir une décision de lieutenant-gouverneur en conseil changeant son nom de Abraham Kirschenzaft à Abraham Kirsch.Ce changement sera applicable également à son épouse, Dame Rosclyn Dora Martin Kirschenzaft et à les enfants à naître de ce mariage.Daté à Montréal, ce 31e jour d'octobre 1973.Les procureurs île requérait!, Mendelsohn Rosentzvek; Shactek, 54566-45-2-0 Taviss Shayne & Levitt.Abraham Kirschenzaft Xotice is hereby given that Abraham Kirschenzaft, Assistant Manager, of the City of Montreal, District of Montreal, and therein residing and domiciled at 2685 Kent Avenue, Apartment 402, will present a Petition to the Minister of Justice for a decree of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Abraham Kirschenzaft to Abraham Kirsch, said change of name to have application anil to inure to the benefit of his wife.Dame Roselyn Dora Martin Kirschenzaft as well as all children to be born of the said marriage.Dated at Montreal, this 31st day of October, 1973.Mendelsohn Rosentzvek; Shacter, Taviss Shayne & Levitt, 54566-45-2-0 Attorneys for Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, tt» 45 6675 Andréa Cantin Avis est donné que monsieur Andréa Cantin, arpenteur-géomètre, domicilié et résidant au 2592 de la rue Montbray, en la cité de Ste-Foy et district de Québec, s'adressera au Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin de faire changer son nom de Andréa Cantin en celui de André Cantin.Québec, ce 26 octobre 1973.54565-45-2-0 Andréa Cantin Take notice that Andréa Cantin, land-surveyor, whose address is 2592 Montbray Street, in Ste-Foy, district of Québec, will apply by petition to the Lieutenant-Governor in Council, Province of Québec, for the purpose of asking him for a decree, changing his name from Andréa Cantin to André Cantin.Québec, this 26th of October, 1973.54565-45-2-0 Walter Michael Chapates Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministère de la justice par monsieur Walter Michael Chapates, superviseur, domicilié à 8897 boulevard LaSalle, apt.122, afin de changer son nom de famille de Chapates pour celui de Chapatis, le tout en conformité avec la Loi du change-dc nom, 1965, S.Q., chapitre 17.Le notaire, 54356-44-2-0 Clément Lamarre.Walter Michael Chapates Notice is hereby given that Mr.Walter Michael Chapates, Foreman, residing at 8897 LaSalle Boulevard, Apt.122, in the City of LaSalle.will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Chapates, to Chapatis, the whole in conformity with the Change of Name Act, 1965, S.Q., chapter 77.Clément Lamarre, 54356-44-2-0 Notary.Diane Couture Diane Couture, secrétaire, résidant et domiciliée au 6030 Des Érables, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom de famille de Couture à Binette.Montréal, le 25 septembre 1973.Les procureurs de la requérante.St-Louis-Labelle, Lafontaine.54357-44-2-0 & Charbonneau.Diane Couture Diane Couture, secretary, residing and domiciled at 6030 Des Érables, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing her name to that of Diane Binette.Montreal, September 25th, 1973.St-Louis-Labelle, Lafontaine, & ClIARBONNEAU, 54357-44-2-0 Attorneys for petitioner.Anthony Czepaitis Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministère de la justice par monsieur Anthony Czepaitis, préposé à la réception, domicilié à 336, 7e Avenue, à LaSalle, afin de changer son nom de famille de Czepaitis pour celui de Chapatis.le tout en conformité avec la Loi du changement de nom, 1965, S.Q., chapitre 17.Le notaire.54358-44-2-0 Clément Lamarre.Anthony Czepaitis Notice is hereby given that Mr.Anthony Czepaiti.% receiver, residing at 336, 7th Avenue, in the City of LaSalle, will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Czepaitis, to Chapatis, the whole in conformity with the Change of Name Act.1965, S.Q., chapter 77.Clément Lamarre, 54358-44-2-0 Notary.Ernest Verret Avis est donné que Ernest Verret, administrateur, domicilié et résidant au 201, Marquis de Tracy, Boucherville, province de Québec, s'adressera au ministre de la justice pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de Ernie King; ce changement sera également applicable à son épouse, née Aima Sicard et à ses enfants mineurs Michel, Linda et Elizabeth, de la même adresse.Daté à Montréal, le 19 octobre 1973.Les procureurs du requérant, Desjardins.Ducharme, Desjardins, 54361-44-2-0 Tellier, Zigby & Michaud.Ernest Verret Notice Is given that Ernest Verret, director, residing and domiciled at 201 Marquis de Tracy, Boucherville, Province of Québec, will apply to the Minister of Justice to obtain an order changing his name to that of Ernie King; such change, will also benefit his wife, nee Alma Sicard.and his minor children Michel.Linda and Elizabeth of the same place.Dated at Montreal, this 19th day of October.1973.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigbv & Michaud, 54361-44-2-0 Attorneys for applicant. 6676 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 10.1973, Vol.105.So.45 Anne Morrine Smith Avis est par la présente donné que Anne Morrine Smith, demeurant au 1737 rue Sanguinet.Montréal, province de Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil d'émettre un décret changeant son nom en celui de Anne Morrine Garner.Montréal, le 11 octobre 1973.I.e.* avocats île la requérante.Ô4360-44-2-o Jacobs & Tannenbaim.Anne Morrine Smith Notice is hereby given that Anne Morrine Smith, residing at 1737 Sanguinct Street, in Montreal.Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Anne Morrine Garner.Montreal.October 11.1973.Jacobs & Tannenbaum.54360-44-2-o Attorneys for applicant.Brenislaus Czepaiies Avis est donné qu'une requête en changement de nom seru présentée au ministre de la justice par M.Brenislaus Czepaiies.Oulilleur, domicilié à 4030.13c Avenue, Laval Ouest, Ville de Laval, afin de changer son nom actuel de Brenislaus Czepaiies.pour celui de Bronnie Chapatis, le tout en conformité avec la Loi du changement de nom 1903 S.Q.chap.77.I.r notaire.54395-44-2-0 Clément Lamarre.Brenislaus Czepaiies Notice is hereby given that Mr.Brenislaus Czepaiies, Die mixer, residing at 4030.13th Avenue, Laval West, Town of Laval, will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Brenislaus Czepaiies.to Bronnie Chapatis, the whole in conformilv with the change of name Act 1965.S.Q.Chapt.77.Clément Lamarre, 54395-44-2-0 A'ofarj,.Nicholas l'apamichalaki» Avis est donné que Nicholas Papamichalakis, étudiant, domicilié et résidant de la cité de Westmount, district de Montréal, province de Québec, et résidant au numéro civique 266 Lanadowm Avenue, Apt.14.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Nicholas Michalis et le nom de sa fille en celui de Gail Michalak Montréal, le 24 septembre 1973.Le.» procureurs du requérant.Tinkoff, Seal Siiaposnick 54396-44-2-0 & Moscowitz.Nicholas Papamichalakis Notice is hereby given that Nicholas Papamichalakis, Student, of the City of Westmount, District of Montreal, in the Province of Québec, and therein residing and domiciled at 266 Lansdowne Avenue, Apartment 14, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Nicholas Michalis and changing the name of his wife to Gail Michalis.Montreal, 24th September, 1973.Tinkoff.Seal, Siiaposnick & Moscowitz, 54396-44-2-0 Attorneys for Applicant.John Anthony Chapates Avis est donné qu'une requête en changement de nom sera présentée au ministère de la Justice par Monsieur John Anthony Chapates.gérant, domicilié à 217 Avenue Stillview, app.808, Pointe-Claire, P.Q.afin de changer son nom de famille de \u2022 Chapates > pour celui de « Chapatis ».le tout en conformité avec « la Loi du changement de nom » 1965 S.Q., chapitre 77.I.t notaire.54409-44-2-o Clément Lamarre.John Anthony Chapates Notice is hereby given that Mr.John Anthony Chapates, manager residing at 217 Stillview, apt.808, Pointe-Claire.P.Q.will present an application to the Minister of Justice for the purpose of obtaining an order of the Lieutenant-!iovernor in Council changing his name from \"Chapates\" to \"Chapatis\".the whole in conformity with the \"Change of Name Act\" 1965 S.Q., Chap.77.Clément Lamarre.54409-44-2-o .Votary.Marcel Boulianne Avis est par les présentes donné que Marcel Boulianne, architecte, demeurant à 635 est, rue Perreault.Rouyn.présentera au ministère de la Justice du Quélicc une requête pour ajouter le prénom de Hubert à ceux qu'il porte déjà.Lf procureur du requérant.54410-44-2-o gustave T ascii ereau, notaire.Marcel Boulianne Notice is hereby given that Marcel Boulianne.architect, domiciled at 635 Perreault Street East.Rouyn, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, to add the first name Hubert to those by which he is presently known.Gustave Tascheheau, notary.54410-44-2-o Attorney for applicant. GAZETTE OFFICIELLE DV QUEBEC.10 novembre 1973.105' année, n' 45 6677 Daniel Fournier Nous donnons avis que Daniel Fournier, commis, domicilié au 4624.rue Lebert.cité de Laval, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de Daniel Lavertu.Montréal, le 26 septembre 1973.Les procureurs du requérant.Goxthier.Barrière & 54359-44-2-0 & Charbonneai.Daniel Fournier Notice il given that Daniel Fournier.clerk, domiciled at 4624 Lebert Street City of Laval.District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Daniel Lavertu.Montreal.September 26.1973.Goxthier, Barrière & Charboxxeau, \u202254359-44-2 Attorneys for applicant.Rachid Maurice Mouawad Avis est donné que Rachid Maurice Mouawad, médecin, domicilié à 45S0 chemin Queen Mary, apt.209, dans la cité et district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice, aux fins de changer son nom à Rachid Maurice Mawad, et aussi pour faire bénéficier son épouse, Marie-Thérèse Rachid Azize Mouawad.et son fils mineur, Maurice Rachid Mouawad, de la même adresse.Montréal, le 24 octobre 1973.Les procureurs du requérant.54397-44-2-0 Garber & Reixblatt.Rachid Maurice Mouawad Notice is given that Rachid Maurice Mouawad, physician, residing at 4580 Queen Mary Road.Apt.209, in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Justice to change his name to Rachid Maurice Mawad, and also to benefit his wife, Marie-Thérèse Rachid Azizc Mouawad.and his minor son, Maurice Rachid Mouawad, of the same address.Montreal, October 24, 1973.Garber & Reixblatt, 54397-44-2-0 Attorneys for applicant.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted David Thomas Basque Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3786 du 22 octobre 1973.d'effectuer le changement de nom de David Thomas Boudreau en celui de David Thomas Basque.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la Justice.54503-o Robert Normand, c.r.David Thomas Basque It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of David Thomas Boudreau to that of David Thomas Basque by order number 3786, dated October 22.1973.Québec, October 30.1973.Robert Normand, q.c 54503-o Deputy M in ister of .1 ustice.Robert Cardinal Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3787 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph Maurice Jean Paul Bernard Cardinal en celui de Robert Cardinal.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice.54503-o Robert Normand.c.r.Robert Cardinal It has pleased the Licutenant-Govermor in Council to change the name of Joseph Maurice Jean Paul Bernard Cardinal to that of Robert Cardinal by order number 3787.dated October 22.1973.Québec.October 30.1973.Robert Normand, q.c.54503-o Deputy Minister of .1 ustice.Marsha Elane Il a plu au lieutenant gouverneur en conseil, par le décret numéro 3788 du 22 octobre 1973.d'effectuer le changement de nom de Marsha Elaine Ekstcin en celui de Marsha Elane.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministie de la .1 ustice.54503-o Robert Normand, c.r.Marsha Elane It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marsha Elaine Ekstein to that of Marsha Elane.bv order number 3788, dated October 22.1973.Québec, October 30.1973.Robert Normand, q.c.54504 Deputy Minister of Justice. 667S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Sorember 10, 1973, Vol.105, So.j5 Joseph Rem?Gaston Guilmet Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3789 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph René Gaston Guillc-mette en celui île Joseph René Gaston Guilmet.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice.54503-o Robert Normand, c.r.Paul Emile Frederic McLean Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3790 du 22 octobre 1973.d'effectuer le changement de nom de Paul-Emile Frederic Brouillet en celui de Paul Emile Frederic McLean.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice.ïl\">03-o Robert Normand, c.r.Joseph Renc Gaston Guilmet It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph René Gaston Guille-mettc to that of Joseph René Gaston Guilmet, by order number 3789, dated October 22, 1973.Québec.October 30, 1973.Robert Normand, q.c.54503 Deputy Minister of J ustice.Paul Emile Frederic McLean It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name ot Paul-Emile Frederic Brouillet to that of Paul Emile Frederic McLean, by order number 3790, dated October 22, 1973.Québec October 30, 1973.Robert Normand, q.c, 54503 Deputy Minister of Justice.Y van Paquin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3791 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph Adélard Armand Y van Dcsehamps en celui de Y van Paquin.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de Injustice.54503-o Robert Normand, c.r.Y van Paquin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Adélard Armand Y van Deschamps to that of Y van Paquin.by order number 3791, dated October 22.1973.Québec.October 30, 1973.Robert Normand, q.c.54503 Deputy Minister of Justice.Katherine April Raffan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3792 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Katherine April Lefebvre en celui de Katherine April Raffan.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice.54503-o Robert Normand, c.r.Katherine April RafTan It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Katherine April Lefebvre to that of Katherine April Raffan, bv order number 3792, dated October 22, 1973.Québec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c, 54503 Deputy Minister of Justice.Mary Beatrice Betty Ann Richardson Mary Beatrice Betty Ann Richardson Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3793 du 22 octobre 1973 d'effectuer le changement de nom de Ann Beatrice Murray en celui de Mary Beatrice Betty Ann Richardson.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54503-o Robert Normand, c.r.Steven Robert Roessler Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3794 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Istvan ROszler en celui de Steven Robert Roessler.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54003 0 Robert Normand, c.r.It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Ann Beatrice Murray to that of Mary Beatrice Betty Ann Richardson, by order number 3793, dated October 22, 1973.Québec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c.54503 Deputy Minister of Justice.Steven Robert Roessler It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Istvan Roszler to that of Steven Robert Roessler, by order number 3794, dated October 22, 1973.Québec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c.54503 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6679 Saul Rothstein Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3795 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Salamon Rotsztajn en celui de Saul Rothstein.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54503-o Robert Normand c.r.Saul Rothstein It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Salamon Rotsztajn to that of Saul Rothstein, by order 3795, dated October 22, 1973.Québec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c, 54503 Deputy M blister of ,1 ustice.Steven Zygmunt Strasser Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3796 du 22 octobre 1973, d'effectuer le changement de nom de Zygmond Strasser en celui de Steven Zygmunt Strasser.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice.54503-o Robert Normand, c.r.Steven Zygmunt Strasser It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Zygmond Strasser to that of Steven Zvgmunt Strasser bv order number 3796, dated October 22, 1973.Québec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c, 54503 Deputy .Minister of Justice.Clifford Taitc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 3797 du 22 octobre 1973.d'effectuer le changement de nom de Clifford Jay Teitelbaum en celui de Clifford Taite.Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54503-o Robert Normand, c.r.Clifford Taite It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Clifford Jay Teitelbaum to that of Clifford Taite by order number 3797, dated October 22, 1973.Quebec, October 30, 1973.Robert Normand, q.c, 54503 Deputy Minister of Justice.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS (Loi des caisses d'épurgne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la requête des caisses d'épargne et de crédit « LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS et « LA CAISSE POPULAIRE DE MELOCHEVILLE ».datée du 23 mars 1973.demandant la confirmation de l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux caisses.Le nom de la caisse résultant de cette fusion est « LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS ».Le siège social de cette caisse est situé au 123 rue Ellice, Beauharnois, dans le district électoral de Beau-liarnois.Le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres sera « St-Étienne-de-Beauharnois, Village de Melocheville, de la Cité de Beauharnois et de la Ville de Maple Grove ».Cette caisse sera affiliée à la Fédération de Québec des Caisses Populaires Desjardins.Québec, le 18 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).54570-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the petition of two savings and credit unions, \"LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS\" and \"LA CAISSE POPULAIRE DE MELOCHEVILLE\", dated March 23, 1973, requesting confirmation of the deed of agreement providing for the amalgamation of these two caisses.The name of the caisse resulting from this amalagma-tion shall be: 'LA CAISSE POPULAIRE DE BEAUHARNOIS\".The head office of this caisse is located at 123 Ellice Street.Beauharnois, in the Electoral District of Beauharnois.The territory in which the caisse shall recruit its members will be \"St.Étienne-de-Beauharnois, Village of Melocheville, the City of Beauharnois and the Town of Maple Grove\".This caisse shall be affiliated to the Fédération de Québec des Caisses Populaires Desjardins.Québec, October 18, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial, 54570 Institutions Companies and Cooperatives. 6680 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Xovember 10, 1973, Vol.105.Xo.j5 Compagnies étrangères Extra-Provincial Companies Siège social Head office_ INTEUROPA ANSTALT FUR HANDEL UND INDUSTRIE Avis est donné que la compagnie « INTEUROPA ANSTALT FUR HANDEL UND INDUSTRIE » constituée en corporation en vertu des articles 534 - 551 du Droit individuel et des Sociétés de la Principauté de Liechtenstein, le 8 juillet 1960, et ayant obtenu l'autorisation de faire affaires dans la province de Québec par un permis émis en date du 5 février 1973.a établi son bureau au numéro 1255.Carré Philippe, suite 608, dans la Ville de Montréal (H3B 301).A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce vingt-cinquième jour d'octobre 1973.Agent de la compagnie Inteuropa dans la province de Québec.54502-o Amedeo Gatti.INTEUROPA ANSTALT FUR HANDEL UND INDUSTRIE Notice is given that \"INTEUROPA ANSTALT FUR HANDEL UND INDUSTRIE\", incorporated under sections 534 - 551 of Individual and Companies Right of the Liechtenstein Principality, on July 8, 1960.and having obtained the authorization to carry on business in the Province of Québec by a licence issued on February 5, 1973, has established its office at 1255 Carré Philippe, Suite 608, in the City of Montreal (H3B 3G1).From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given at Montreal, this twenty-fifth day of October, 1973.Amedeo Gatti, Agent for Inteuropa Company in the 54502 Province of Québec.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses C I F CREDIT & INTERNATIONAL FINANCE CORP.ESTABLISHMENT Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « C I F CREDIT & INTERNATIONAL FINANCE CORP.ESTABLISHMENT » a été autorisée à faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Jules Blond, notaire, 1103 Tour de la Bourse, 800, Place Victoria, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 1103 Tour de la Bourse, 800, Place Victoria, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jessop.54432 PA: 3-73 ROCKWOOD CANADA, INC.Avis est donné que le 30e jour du mois de mai 1973, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un nouveau permis à la compagnie « LEVIN-TOWNSEND CANADA, INC.\" l'autorisant à exercer son commerce dans la province sous son nouveau nom de « ROCKWOOD CANADA.INC.», en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères chapitre 282 des Statuts refondus 1964.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jessop.04432 PA: 60-67 C I F CREDIT & INTERNATIONAL FINANCE CORP.ESTABLISHMENT Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"C I F CREDIT & INTERNATIONAL FINANCE CORP.ESTABLISHMENT\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Jules Blond, notary, 1103 Stock Exchange Tower, 800 Place Victoria, Montreal.The principal offire of the company in the Province is at 1103 Stock Exchange Tower, 800 Place Victoria, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, deting Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54432-0 PA: 3-73 ROCKWOOD CANADA, INC.Notice is given that, on 30th day of May, 1973, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, to \"LEVIN-TOWNSEND CANADA, INC.\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"ROCKWOOD CANADA, INC.\".pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.Albert Jessop, Acting Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54432-0 PA: 60-67 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n\" 45 6681 ARMCO RECREATIONAL ENTERPRISES, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « ARMCO RECREATIONAL ENTERPRISES, INC.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-minislrc associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jessop.51-132 PA : 42-73 ARMCO RECREATIONAL ENTERPRISES, INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"ARMCO RECREATIONAL ENTERPRISES, INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, judicial District of Québec.Albert Jessop, Acting Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54432-0 PA: 42-73 CONSOLIDATED LOUANNA GOLD MINES LIMITED Avis est donné que le 10e jour du mois d'octobre 1973.le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un nouveau permis à la compagnie « LOUANNA GOLD MINES LIMITED » l'autorisant à vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, dans la province de Québec sous son nouveau nom de « CONSOLIDATED LOUANNA GOLD MINES LIMITED », en vertu de pouvoirs conférés par la Loi des compagnies minières, chapitre 283 des Statuts refondus, 1964.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), Albert Jessop.54432 PVA: 8-64 CONSOLIDATED LOUANNA GOLD MINES LIMITED Notice is given that, on 10th day of October, 1973.a new license was granted by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives to \"LOUANNA GOLD MINES LIMITED\", authorizing it to sell, or otherwise alienate, directly or indirectly, in the Province of Québec under its new name of \"CONSOLIDATED LOUANNA GOLD MINES LIMITED\", in virtue of the powers conferred by the Mining Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 283.Albert Jessop, Acting Associate Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.54432-0 PA: 8-64 STANFORD MINES LIMITED Avis est donné que la compagnie « STANFORD MINES LIMITED » a été autorisée à vendre, ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, stocks, certificats d'actions, obligations et autres valeurs.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Guy E.Boisvert suite 2610, 800, boulevard Dorchester ouest.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est établi à suite 2610, 800.boulevard Dorchester ouest, Montreal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), Albert Jessop.54432 PVA: 4-73 STANFORD MINES LIMITED Notice is given that \"STANDORD MINES LIMITED\", has been authorized to sell, or otherwise alinate in the Province of Québec, its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company, is Mr.Guy E.Boisvert.Suite 2610.800 Dorchester Boulevard West, Montreal.The principal office of the said company in the Province is at Suite 2610.800 Dorchester Boulevard West.Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Acting Associate Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.54432-0 PVA: 4-73 6682 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November JO, 1973, Vol.105, No.45 ELECTRONICS FOR MEDICINE, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « ELECTRONICS FOR MEDICINE, INC.» a été autorisée à faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jessop.54432 PA: 85-73 ELECTRONICS FOR MEDICINE, INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"ELECTRONICS FOR MEDICINE.INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, judicial District of Québec.Albert Jessop.Acting Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54432-0 PA: 85-73 Compagnies étrangères Agent Extra-Provincial Companies Agent LEVLN-TOWNSEND CANADA, INC.Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 17 mai 1973, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, M.William Desmond Thomas, 505, boulevard Dorchester ouest.Montréal, a été nommé en remplacement de M.William Alston Campbell à titre d'agent principal dans la province de « LEVIN TOWN-SEND CANADA, INC.», une compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est établi au 505.boulevard Dorchester ouest, (4e étage), Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54506 Albert Jessop LEVIN-TOWNSEND CANADA, INC.Notice is given that, by new power of attorney dated May 17th, 1973, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.William Desmond Thomas, 505 Dorchester Boulevard West, Montreal, was appointed to replace Mr.William Alston Campbell as chief agent in the Province of \"LEVLN-TOWNSEND CANADA, INC.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.The principal office of the said company in the Province is at 505 Dorchester Boulevard West, (4th Floor), Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial 54506-o Institutions, Companies and Cooperatives.Associations coopératives CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DES BOIS-FRANCS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DES BOIS-FRANCS ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Victoriaville, Québec, dans le district électoral d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54504-o Albert Jessop.Cooperative Associations CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DES BOIS-FRANCS (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DES BOIS-FRANCS\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Victoriaville, Québec, in the electoral District, of Arthabaska.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial 54504 Institutions, Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 1,5 6683 Députés élus Bureau du Président général des élections Québec, le 6 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés, les candidats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Louis-Hébert Monsieur Gaston Desjardins.avocat.3196, Marso-let, Sainte-Foy.\u2014 Parti libéral du Québec Anjou Monsieur Yves Tardif, avocat, 755, boulevard Montpellier, app.803, Saint-Laurent.\u2014 Parti libéral du Québec Ahgenteiii.Monsieur Zoël Saindon, médecin chirurgien, 176, Saint-Jacques, Lachute.\u2022\u2014 Parti libéral du Québec Beauharnois Monsieur Gérard Cadieux, homme d'affaires, 13> Terrasse Louise, Salaberry-de-Valleyfield.\u2014 Parti libéral du Québec Bourassa Mademoiselle Lise Bacon, gérante, 4-10 est.rue Sherbrooke, app.1405.Montréal 132.\u2014 Parti libéral du Québec Chambly Monsieur Guy Saint-Pierre, ingénieur, 1855, Sommet Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville.\u2014 Parti libéral du Québec Châteauguay Monsieur George Kennedy, comptable agréé, 26, Croissant Richard, Châteauguay-Centre.\u2014 Parti libéral du Québec Crémazie Monsieur Jean Bienvenue, avocat, 41, Somerville, Montréal 357.\u2014 Parti libéral du Québec D'Arcy McGee Monsieur Victor Charles Goldbloom, médecin.5.Grove Park, Westmount, Montréal 217.\u2014 Parti libéral du Québec Deux-Montagnes Monsieur Jean-Paul L'Allier, avocat, 74, 17e Avenue, Deux-Montagnes.\u2014 Parti libéral du Québec Drummond Monsieur Robert Malouin, ingénieur, 575, rue Ferland, Drummondville.\u2014 Parti libéral du Québec Members Elected Office of the Chief Returning-Offîcer Québec, November 6, 1973.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new National Assembly of Québec.Louis-Hébert Mr.Gaston Desjardins, Advocate, 3196, Marsolet, Sainte-Foy.\u2014 Québec Liberal Party Anjou Mr.Yves Tardif, Advocate, 755, Montpellier Boule-vard, apt.803, Saint-Laurent.\u2014 Québec Liberal Party Argenteuil Mr.Zcël Saindon, General Practitioner, 176 Saint-Jacques, Lachute.\u2014 Québec Liberal Party Beauharnois Mr.Gérard Cadieux, Business man, 13, Terrasse I/Ouisc, Salaberrv-de-Yallevfield.\u2014 Québec Liberal Par- ty Bourassa Miss Lise Bacon, Manager, 440, Sherbrooke Street East, apt.1405.Montreal 132.\u2014 Québec Liberal Party Chambly Mr.Guy Saint-Pierre.Engineer, 1855, Sommet Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville.¦\u2014 Québec Liberal Party Châteauguay Mr.George Kennedy, Chartered Accountant, 26, Croissant Richard, Châteauguay-Centre.\u2014 Québec Liberal Party Crémazie Mr.Jean Bienvenue, Advocate, 41, Somerville, Montreal 357.\u2014 Québec Liberal Party D'Arcy McGee Mr.Victor Charles Goldbloom, Physician, 5, Grove Park, Westmount, Montreal 217.\u2014 Québec Liberal Party.Two Mountains Mr.Jean-Paul L'Allier, Advocate, 74, 17th Avenue, Two Mountains.\u2014 Québec Liberal Party Drummon d Mr.Robert Malouin, Engineer, 575, Ferland Street, Drummondville.\u2014 Québec Liberal Party (iliS-l QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Sorember 10.1973.Vol.105.So.jo F ABIE Monsieur Gilles Houdc.éducateur, 1625, boulevard Leblanc, Laval.\u2014 Parti libéral du Québec Huntingdon Monsieur Kenneth Fraser, cultivateur.Dundee, (Huntingdon).\u2014 Parti libéral du Québec Iberville Monsieur Jacqucs-R.Tremblay, administrateur en relations publiques.2250.rue Union.Saint-Césaire, (Iberville).\u2014 Parti libéral du Québec Jacques-Cartier Monsieur Noël St-Germain, optométriste, 100.53e Avenue.Lachine.\u2014 Parti libéral du Québec .1e a s s e- M a kce Monsieur Aimé Brisson.comptable agréé, 5944, boulevard L'Assomption.Montréal 410.\u2014 Parti libéral du Québec L'Al'ADl K.Monsieur Francois Cloutier, médecin, 1274.boulevard Mont-Royal, Montréal 153.\u2014 Parti libéral du Québec Lafontaixe Monsieur Marcel Léger, administrateur.6025.Mer-riam, Anjou.\u2014 Parti Québécois Laprairie Monsieur Paul lierthiaumc.conseiller en informatique, 3170.Belvédère, Brossard.\u2014 Parti libéral du Québec Laurentides-Labelle Monsieur Roger Lapointe.administrateur scolaire, 319, rue des Ormes, Mont-Laurier.\u2014 Parti libéral du Québec Laurier Monsieur André Marchand, imprimeur.154.rue Dcsmarteau.Laval.\u2014 Parti libéral du Québec Lavai.Monsieur Jean-Noël Lavoie.notaire.4180, Ire Rue, Laval.\u2014 Parti libéral du Québec Maisonneuve Monsieur Robert Burns, avocat syndicaliste, 3655, Papineau, app.803, Montréal.\u2014 Parti Québécois L'Assomption Monsieur Jean Perreault, ingénieur, 5, boulevard I Ange-Gardien.L'Assomption.\u2014 Parti libéral du Québec F abbe Mr.Gilles Houde, Educator, 1625, Leblanc Boulevard.Laval.\u2014 Québec I.ibeial Party Hi ndington Mr.Kenneth Fraser.Farmer, Dundee, (Huntingdon).\u2014 Québec Liberal Party Iberville Mr.Jacques-R.Tremblay, Public relations manager, 2250.Union Street, Saint-Césaire, (Iberville).\u2014 Québec Liberal Party Jacques-Cartier Mr.Noël St-Germain.Optometrist.100, 53rd Avenue, Lachine.\u2014 Québec Liberal Party Jeanne-Mame Mr.Aimé Brisson, Chartered Accountant, 5844, L'Assomption Boulevard, Montreal 410.\u2014 Québec Liberal Party.L'Acadie Mr.François Cloutier, Physician, 1274, Mont-Royal Boulevard, Montreal 153.\u2014 Québec Liberal Party Lafontaixe Mr.Marcel Léger, Administrator, 6025, Merriam, Anjou.\u2014 Parti Québécois Laprairie Mr.Paul Bcrthiaume, Data-processing adviser, 3170, Belvédère, Brossard.\u2014 Québec Liberal Party Lai rentides-Labeli.e Mr.Roger Lapointe.School administrator, 319, des Ormes Street.Mont-laurier.\u2014 Québec Liberal Party Laurier Mr.André Marchand.Printer, 154, Desmarteau Street, Laval.\u2014 Québec Liberal Party Laval Mr.Jean-Noël I.avoie.Notary.4180, 1st Street, (.aval.\u2014 Québec Liberal Party Maisonneuve Mr.Robert Burns.Trade union lawyer, 3655, Papineau, apt.803.Montreal.\u2014 Parti Québécois L'Assomption Mr.Jean Perreault, Engineer, 5, l'Angc-Gardien Boulevard.L'Assomption.\u2014 Québec Liberal Party GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6685 Marcuerite-Bourgeoys Monsieur Fernand Lalondc.avocat.4902.Roslyn, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Mercier Monsieur Robert Bourassa.avocat et économiste, 190.Maplewood, Outremont.\u2014 Parti libéral du Québec Miu.e-1i.es Monsieur Bernard Lacltance, administrateur, 3833-rue Groulx.Laval.\u2014 Parti libéral du Québec Moxt-Royai.Monsieur .1.B.(John) Ciaccia, avocat, 110, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield.\u2014 Parti libéral du Québec Le président général des élections, Juge de la Cour prorineialt.54774-0 François Drouix.Marguekite-Bouroeoys Mr.Fcrnand Lalonde, Advocate, 4902, Roslyn Montreal.\u2014 Québec Liberal Party Mercier Mr.Robert Bourassa, Advocate and Economist, 190, Maplewood, Outremont.\u2014 Québec Liberal Party Mille-Iles Mr.Bernard l.acliance, Administrator, 3833, Groulx Street, Laval.\u2014 Québec Liberal Party Mount-Royal Mr.1.B.(John) Ciaccia, Advocate, 110, Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield.\u2014 Québec Liberal Party François Drouix, Chief Returtiiug-Officer, 54774-o Judge of the Provincial Court.Bureau du Président general des élections Québec, le 6 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députes, les candidats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Xotre-Dame-de-Grâce Monsieur William Tetley.avocat.112.avenue Cornwall, Mont-Royal.\u2014 Parti libéral du Québec Outremont Monsieur Jérôme Choquette.avocat, 7.rue Nelson.Outremont.\u2014 Parti libéral du Québec Poixte-Claire Monsieur Arthur-E.Séguin, administrateur.64.avenue Saint-Louis, Pointe-Claire.\u2014 Parti libéral du Québec Prévost Monsieur Bernard-A.Parent, administrateur, 416.Grande-Allée, Saint-Jérôme.\u2014 Parti libéral du Québec.Richelieu Monsieur Claude Simard, industriel, 801, boulevard Laird, Mont-Royal.\u2014 Parti libéral du Québec Robert Baldwin Monsieur Jean Cournoyer.avocat, 18.Banff, Dollard-des-Ormeaux.\u2014 Parti libéral du Québec Rosemoxt Monsieur Gilles Bellemare, gérant de district, 4303 rue Bélanger.Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Office of the Chief Returning-Officer Québec, November 6, 1973.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new National Assembly of Québec : Notre-Dame-de-Grâce Mr.William Tetley, Advocate.112, Cornwall Avenue, Mount-Royal.\u2014 Québec Liberal Party Outremont Mr.Jérôme Choquette.Advocate.7.Nelson Street.Outremont.\u2014 Québec Liberal Party Pointe-Claire Mr.Arthur-E.Séguin.Administrator.64, Saint-Louis Avenue, Pointe-Claire.\u2014 Québec Liberal Party Prévost Mr.Bernard-A.Parent, Administrator, 416.Grande-Allée, Saint-Jérôme.\u2014 Québec Liberal Party Richelieu Mr.Claude Simard, Industrialist, 801, Laird Boulevard, Mount-Royal.\u2014 Québec Liberal Party Robert Baldwin Mr.Jean Cournoyer, Advocate, 18, Banff, Dollard-des-Ormeaux.\u2014 Québec Liberal Party Rosemont Mr.Gilles Bellemare, District manager, 4303, Bélanger Street, Montreal.\u2014 Québec Liberal Party titisf, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Sorember 10.1073, Vol.105.No.1,5 Sainte-Anne Monsieur George P.Springate.sportif et homme d'affaires, 3940, chemin de la Côte-des-Neiges, app.B5ô, Montréal.\u2014 Parti libéral du Quélicc Saint-Henri Monsieur Gérard Shanks, relationniste, 6959, rue Hadley, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec.Saint-Hyacinthe Monsieur Fernand Cornellier.administrateur.504' rue Saint-Pierre, La Providence.\u2014 Parti libéral du Québec.Saint-Jacques Monsieur Claude Charron, enseignant 185.place d'Youville.app.2.Montréal.\u2014 Parti Québécois.Saint-Jean Monsieur Jacques Yeilleux.professeur, 456, Neuve-France, Saint-Jean.\u2014 Parti libéral du Québec Saint-Laurent Monsieur Claude-E.Forget, économiste, 957, Dun\" lop, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Saint-Louis Monsieur Harry Blank, avocat 4625.avenue Miller-Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Sauve Monsieur Jacques-Y van Morin.avocat et professeur.1201.boulevard Mont-Royal.Montréal.\u2014 Parti Québécois Terrebonne Monsieur Denis Hardy, avocat, 699.Carré Dumav Sainte-Thérèse.\u2014 Parti libéral du Québec Vaudreuil-Soilanges Monsieur Paul Phaneuf.administrateur.29.1er Boulevard.Terrasse- Vaudreuil.\u2014 Parti libéral du Québec.Verchères Monsieur Marcel Ostiguy.industriel.806.du Château, Mont-Saint-Hilaire.\u2014 Parti libéral du Québec Verdi n Monsieur Lucien Caron, administrateur, 71 15, avenue Churchill, Verdun.\u2014 Parti libéral du Québec VlAU Monsieur Fernand Picard, industriel.4250 est.boulevard Métropolitain, app, 18.Saint-Léonard.\u2014 Parti libéral du Québec Sainte-Anne Mr.George P.Springate.Sportsman and Business man.3940.Côte-des-Neiges Road, apt.B55.Montreal.\u2014 Québec Liberal Party.Saint-Henri Mr.Gérard Shanks, Public relations officer.6959, Hadley Street, Montreal.\u2014 Québec Liberal Party Saint-Hyacinthe Mr.Fernand Cornellier, Administrator, 504, Saint-Pierre Street, La Providence.\u2014 Québec Liberal Party Saint-Jacques Mr.Claude Charron, Teacher.185.d'Youville Place, apt.2, Montreal.\u2014 Parti Québécois Saint-Jean Mr.Jacques Yeilleux, Professor, 456, Neuve-France, St John's.\u2014 Québec Liberal Party Saint-Laurent Mr.Claude-E.Forget Economist, 957, Dunlop, Montreal.\u2014 Québec Liberal Party Saint-Louis Mr.Harry Blank.Advocate, 4625.Miller Avenue, Montreal.\u2014 Québec Liberal Party Sauvé Mr.Jacques-Y van Morin.Advocate and Professor, 1201, Mont-Royal Boulevard.Montreal.\u2014 Parti Québécois.Terrebonne Mr.Denis Hardy, Advocate, 699.Carré Dumay, Sainte-Thérèse.\u2014 Québec Liberal Party Vaudreuil-Soulanoes Mr.Paul Phaneuf, Administrator, 29.1st Boulevard.Terrassc-Yaudreuil.\u2014 Québec Liberal Party Verchères Mr.Marcel Ostiguy, Industrialist.806.du Château, Mont-Saint-Hilaire.\u2014 Québec Liberal Party Verdun Mr.Lucien Caron, Administrator, 7145.Churchill Avenue.Verdun.\u2014 Québec Liberal Party VlATJ Mr.Fernand Picard.Industrialist, 4250 Métropolitain Boulevard East apt.18.Saint-Léonard.\u2014 Quebec Liberal Party GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 197S, 105' année, n\" J,5 66S7 Westmouxt Monsieur Thomas Kevin Drummonrl, administrateur, 3690.de la Montagne, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Le président général des élections.Juge de la Cour provinciale.54774-o François Drouix.Bureau du Président général des élections Québec, le 6 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés, les candidats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Lotbixière Monsieur Georges-J.-P.Massicottc.agronome, 161, rue Normand.Saint-Agapit.\u2014 Parti libéral du Québec Beau ce-Nord Monsieur Denis Sylvain, avocat, 240, rue du Collège, Sainte-Marie.\u2014 Parti libéral du Québec Charlevoix Monsieur Raymond Mailloux, homme d'affaires, 23, boulevard l.cclcrc.Baie-Saint-Paul.\u2014 Parti libéral du Québec Roberval Monsieur Robert Lamontagne, notaire, 599, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien.-\u2014 Parti libéral du Québec Gouin Monsieur Jean-M.Beauregard, administrateur, 1321 ouest, rue Sherbrooke, app.C30, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec Levis Monsieur Vincent Chagnon, administrateur, 21, avenue Christ-Roi, Lévis.\u2014 Parti libéral du Québec Taschereau Monsieur Irénée Bonnier, directeur de développement, 623, Commerciale, Saint-David.\u2014 Parti libéral du Québec Limoilou Monsieur Fernand Houde, comptable, 2125, de l'Émérillon, Québec 3.\u2014 Parti libéral du Québec Vanier Monsieur Fernand Dufour, médecin, 222, rue Beau-cage, Vanier.\u2014 Parti libéral du Québec Montmorency Monsieur Marcel Bédard, ingénieur conseil, 100, rue Dugas, Beauport.\u2014 Parti libéral du Québec Westmount Mr.Thomas Kevin Drummond.Administrator, 3690, de la Montagne.Montreal.\u2014 Québec Liberal Party François Drouix, Chit} Returning-Officer, 54774-0 Judge of the Provincial Court.Office of the Chief Returning-Officer Québec, November 6, 1973.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new National Assembly of Québec: Lotbixière Mr.Georges-J.-P.Massicotte.Agronomist, 161, Normand Street, Saint-Agapit.\u2014 Quel«?c Liberal Party Beauce-North Mr.Denis Sylvain, Advocate, 240.du Collège Street, Sainte-Marie.\u2014 Québec Liberal Party Charlevoix Mr.Raymond Mailloux, Business man, 23, Leclerc Boulevard.Baie-Saint-Paul.\u2014 Québec Liberal Party Roberval Mr.Robert Lamontagne, Notary, 599, Sacré-Coeur Boulevard, Saint-Félicien.\u2014 Québec Liberal Party Gouix Mr.Jean-M.Beauregard, Administrator.1321.Sherbrooke Street West.apt.C30, Montreal.\u2014Québec Liberal Party Levis Mr.Vincent Chagnon, Administrator.21, Christ-Roi Avenue, Levis.\u2014 Québec Liberal Party Taschereau Mr.Irénée Bonnier, Development manager, 623, Commerciale, Saint-David.\u2014 Québec Liberal Party Limoilou Mr.Fernand Houde, Accountant, 2125, de l'Émérillon, Québec 3.\u2014 Québec Liberal Party Vaxier Mr.Fernand Dufour.Physician.222.Beaucage Street, Vanier.\u2014 Québec Liberal Party moxtmorexcy Mr.Marcel Bédard, Consulting engineer, 100, Dugas Street, Beauport.\u2014 Québec Liberal Party C.C.SS QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1(173, Vol.105, No.1,5 MOSTM ao S Y-L'IsLET Monsieur Julien Giasson.courtier d'assurances, easier postal 100.l.'Islet.\u2014 Parti liberal du Québec Jean-Talon Monsieur Raymond1 Garncau, économiste, 823, du Coteau, Sainte-Foy.\u2014 Parti libéral du Québec Le président général des élections.luge de la Cour provinciale, 54774-0 François Ditonx.MoNTMACNY-LTsLET Mr.Julien Giasson, Insurance Broker.P.Q.Box 100, L'Islet.\u2014 Québec Liberal Party .Ieax-Taix)X Mr.Raymond Garneau, Economist.823, du Coteau, Sainte-Foy.\u2014 Québec Liberal Party François Drouix, Chief Returning-Officer, 54774-0 Jugde of the Provincial Court.liiircau du Président general des élections Québec, le 6 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés, les candidats ci-après désignés, pour les représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Charlesbourg Monsieur André Harvey, publicitaire conseil.1543.place Bourbonnais.Orsainvillc.\u2014 Parti libéral du Québec Chai veau Monsieur Bernard Lacliapelle.ingénieur.2734.de l'Anse.Sainte-Foy.\u2014 Parti libéral du Québec Beaice-Suu Monsieur Fabien Roy.administrateur, 1375, Se Avenue, Saint-Georges-Oucst.\u2014 Parti Créditiste Bellechasse Monsieur Pierre Mercier, administrateur, 4175 est.5e Avenue, app.1, Cliarlesbourg.\u2014Parti libéral du Québec Le président général des élections.1 uge de la t 'our provinciale.54774-0 François Drouix.Office of the Chief Returning-Officer Québec.November 6, 1973.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent the following electoral divisions in the new National Assembly of Quebec: Charlesbourg Mr.André Harvey, Advertising consultant, 1543, Bourbonnais Place.Orsainville.\u2014 Québec Liberal Party Chauveau Mr.Bernard Lacliapelle, Engineer, 2734.de l'Anse, Sainte-Foy.\u2014 Québec Liberal Party Beauce-South Mr.Fabien Roy, Administrator, 1375, 8th Avenue, Saint-Georges-Ouest.\u2014 Créditiste Party Bellechasse Mr.Pierre Mercier.Administrator, 4175.5th Avenue East.apt.I, Charlesbourg.\u2014 Québec Liberal Party François Drouix, Chief Returning-Officer, 54774-0 ./udge of the Provincial Court.Bureau du Président général des élections Québec, le 6 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que les collèges électoraux suivants ont élu députés, les candidats ci-après désignes, pour les représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Champlain Monsieur Normand Toupin, directeur.621, rue Corbin, Cap-de-la-Madeleine.\u2014 Parti libéral du Québec JoLIETTE-.MoXTCAL.m Monsieur Robert Qucnneville, médecin, 365, boulevard Manscau, Joliette.\u2014 Parti libéral du Québec Office of the Chief Returning-Officer Québec, November 6, 1973.I hereby give notice that the candidates herein after mentioned have been returned as deputies to represent Ihc following electoral divisions in the new National Assembly of Quebec: Champlain Mr.Normand Toupin, Manager, 621, Corbin Street, Cap-de-la-Madeleine.\u2014 Québec Liberal Party Joli ette-Moxtcalm Mr.Robert Quenneville.Physician.365, Manseau Boulevard, Joliette.\u2014 Québec Liberal Party GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1973, 105' année, n° 45 6689 Arthabaska Monsieur J.-Gilles Massé, administrateur, 1051 sud, boulevard Bois-Francs, Arthabaska.\u2014 Parti libéral du Québec Maskinongf.Monsieur Yvon Picotte, principal d'école, 900.Petit Bois, l,ouiseville.\u2014 Parti libéral du Québec Richmond Monsieur Yvon Yallières, professeur, Route ruiale no 2, casier postal no 1, Danville.\u2014 Parti libéral du Québec Portneuf Monsieur Michel Page, secrétaire-particulier.12, rue Dollard, Saint-Basile.\u2014 Parti libéral du Québec Dekthikk Monsieur Michel Denis, gérant, 2281, rang Saint-Pierre, Saintc-Elizabeth.\u2014 Parti libéral du Québec Lac-Saint-Jean Monsieur Roger Pilote, administrateur, 610, avenue Martel, Aima.\u2014 Parti libéral du Québec Dubuc Monsieur Ghislain Harvey, bachelier en sciences humaines, 1153, 2e Avenue, Port-Alfred.\u2014 Parti libéral du Québec Abitibi-Ouest Monsieur Jean-Hugues Boutin, administrateur, 71 est, 3e Avenue, Amos.\u2014 Parti libéral du Québec RoUYN-NoRANDA Monsieur Camille Samson, vendeur, 371, rue Tardif, Rouyn.\u2014 Parti Créditiste Trois-Rivières Monsieur Guy Bacon, relationniste, 2360, boulevard du Carmel.Trois-Rivières.\u2014 Parti libéral du Québec Saint-François Monsieur Gérard Déziel, maître-électricien, 668, Chalifoux, Sherbrooke.\u2014 Parti libéral du Québec Orford Monsieur Georges Yaillancourt, marchand, 83, Wellington, Coaticook.\u2014 Parti libéral du Québec Johnson Monsieur Jean-Claude Boutin, avocat, 36, Crabtree, Windsor.\u2014 Parti libéral du Québec Hull Monsieur Oswald Parent, administrateur, 135, boulevard Gamelin, app.403, Hull.\u2014 Parti libéral du Québec Arthabaska Mr.J.-Gilles Massé, Administrator, 1051, Bois-Francs Boulevard South, Arthabaska.\u2014 Québec Liberal Party Maskinongé Mr.Yvon Picotte, school principal, 900, Petit Bois, Louiseville.\u2014 Québec Liberal Party Richmond Mr.Yvon Yallières.Professor, Rural Road No.2, P.O.Box No.1, Danville.\u2014Québec Liberal Party Portneuf Mr.Michel Page, Private secretary, 12, Dollard Street, Saint-Basile.\u2014 Québec Liberal Party Bekihiek Mr.Michel Denis, Manager, 2281, Saint-Pierre Range, Sainte-Elizabeth.\u2014 Québec Liberal Party Lac-Saint-Jean Mr.Roger Pilote, Administrator, 610, Martel Avenue, Aima.\u2014 Québec Liberal Party Dubuc Mr.Ghislain Harvey, Bachelier en sciences humaines, 1153, 2nd Avenue, Port-Alfred.\u2014 Québec Liberal Party Abitibi-West Mr.Jean-Hugues Boutin, Administrator, 71, 3rd Avenue East, Amos.\u2014 Québec Liberal Party ROUYN-NORANDA Mr.Camille Samson, Salesman, 371, Tardif Street Rouyn.\u2014 Créditiste Party Trois-Rivières Mr.Guy Bacon, Public relations officer, 2360, du Carmel Boulevard, Trois-Rivières.\u2014 Québec Liberal Party Saint-François Mr.Gérard Déziel, Master electrician, 668, Chalifoux, Sherbrooke.\u2014 Québec Liberal Party Orford Mr.Georges Yaillancourt, Merchant, 83, Wellington, Coaticook.\u2014 Québec Liberal Party Johnson Mr.Jean-Claude Boutin, Advocate, 36 Crabtree, Windsor.\u2014 Québec Liberal Party Hull Mr.Oswald Parent, Administrator, 135, Gamelin Boulevard, apt.403, Hull.\u2014 Québec Liberal Party 6690 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November lO, 1973, Vol.105, So.',5 Pontiac-Témiscamingue Monsieur Jean-Guy Larivière, commerçant, Campbell's Bay.\u2014 Parti libéral du Québec Papineau Monsieur Mark Assad, professeur, 509, rue Principale.Buckingham.\u2014 Parti libéral du Québec Gatineau Monsieur Michel Gratton, ingénieur, 16, rue Normandie, Hull.\u2014 Parti libéral du Québec.Saint-Mai hick Monsieur Marcel Bérard, professeur, 905, 119c Rue, Shawinigan-Sud.\u2014 Parti libéral du Québec aI eg antic-com ptox Monsieur J.-Orner Dionne, cultivateur, Route rurale no 5, Cookshire.\u2014 Parti libéral du Québec Sherbrooke Monsieur Jean-Paul Pépin, représentant des ventes, 2780.Maricourt, Sherbrooke.\u2014 Parti libéral du Québec Frontenac Monsieur Henri Lecours, médecin.191, rue Gagné, Coleraine.\u2014 Parti libéral du Québec Sheftord Monsieur Richard Vcrrcault, administrateur, 279, rue Déragon, Granby.\u2014 Parti libéral du Québec Bhome-Missisquoi Monsieur Glen Brown, cultivateur.Route rurale no 2, Knowlton.\u2014 Parti libéral du Québec Jonquière Monsieur Gérald Harvey, comptable, 294, rue de la Bretagne.Jonquière.\u2014 Parti libéral du Québec PONTIAC-TÉMISCAMINCUF.Mr.Jean-Guy Larivière, Trader, Campbell's Bay.\u2014 Québec Liberal Party Papineau Mr.Mark Assad, Professor, 509, Principale Street, Buckingham, \u2014 Québec Liberal Party Gatineau Mr.Michel Gratton, Engineer, 16, Normandie Street, Hull.\u2014 Québec Liberal Party Saint-Mauhice Mr.Marcel Bérard.Professor.905, 119th Street, Shawinigan-South.\u2014 Québec Libeial Party M É NIERE INC., a body politic No.13-755 j and corporate, having its principal J, place of business at 35 Place Bilo-deau.Val St.Michel, District of Québec, versus SEBASTIEN LAPOINTE, domiciled and residing at 11 - 36th Street, Val St.Michel, District of Québec.\"An emplacement located in the Town of Val St.Michel, County of Québec, and comprising: (a) The lot known and described as number sixty-six, subdivision of original lot number three hundred twenty-three (323-66) on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-.Ieune-Lorette, Québec Registration Division; said lot measuring seventy-five feet (75') in width by one hundred feet (100') in depth, English measure.(b) The northeast part of the lot known and described as number sixty-five, subdivision of original lot number three hundred twenty-three (N.E.Pt.323-65) of same cadastre; said part of lot measuring five feet (5') in width by one hundred feet (100') in depth, that is the whole depth of said lot, English measure, and bounded as follows: on the northwest by lot 324, on the northeast by lot 323-66, on the southeast by 36th Street (323-70), and on the southwest by the remaining part of said lot 323-65.With the house erected on said emplacement, appurtenances and dependencies, said house bearing civic number 11 on 36th Street, in Val St.Michel.\" To be sold at the Québec Registry Office, 10 Chauveau Avenue, Québec, on the SEVENTEENTH day of the month of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 6, 1973.54579 TERREBONNE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne j -p EORGES EMILE CHARRON, gen-No.66.355.S tleman, domiciled and residing at I 651 Taschereau Street, in the City of 6726 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1973, Vol.105, No.45 Ste-Thérèse, district de Terrebonne, demandeur, vs EMBASSY ESTATES CORP., corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au No 3300, rue Cavendish, suite 500, Montréal 261, district de Montréal, défenderesse.Avis de veille L'immeuble ci-après désigné et en la possession de la défenderesse, savoir: « Une terre située dans la concession de la Côte St-Louis, en la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, connue et désignée comme étant le lot numéro quatre cent quarante (440) au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse-de-Blainville, contenant environ cinquante-huit arpents en superficie: avec maison et autres bâtisses y élevées; Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Terrebonne situé chambre 106, Palais de Justice Saint-Jérôme, MARDI le ONZIÈME jour de DÉCEMBRE 1973 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Mum.St-Jérôme, le 31 octobre 1973.54544-o Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal { \"T-TOMEPLAN REALTY LIM-No 05-008342-73.s * -I ITED, une corporation léga- ' lement incorporée en vertu des Lois de la province d'Ontario, ayant son siège social dans le comté de York, en la cité de Toronto, province d'Ontario, et une succursale en la cité de Montréal, province de Québec, au 6625 est de la rue Sherbrooke, demanderesse, vs SERGE BEAUDOIN, technicien, résidant et domicilié au 3405 rue Evelyn, des cité et district de Montréal, défendeur.Avis de vente « Un emplacement situé en la paroisse de Ste-Sophie, division d'enregistrement de Terrebonne, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro trois cent soixante-sept (Ptie 367) au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Sophie, décrit par les lettres A B C D E F G A sur un plan préparé par M.Hubert Murray, a.g., en date du 24 juillet 1971, sous le No 4201 et annexé à un acte de vente passé devant Me Jean Morin, notaire, ie 24 septembre 1971, sous le Xo 1571 de ses minutes, enregistré à Terrebonne, sous le No 391514, dont le point A est situé à cent pieds (100') mesuré dans une direction nord-ouest, de l'intersection de l'emprise nord-ouest de la rue 367-63 et de la rue 367-65.L'angle B-A-G est un angle droit.Borné au nord-ouest et au nord par une rue projetée et partie 367; au nord-est par la rue 367-65; au sud-est et sud-ouest par partie du lot 367.Ste.Thérèse, District of Terrebonne, plaintiff, vs EMBASSY ESTATES CORP., a corporation legally incorporated, having a place of business at 3300 Cavendish Street, Suite 500, Montreal 261, District of Montreal, defendant.Notice of Sale The immoveable hereinafter described and in the possession of the defendant, to wit: \"A farm located in the concession of Côte St.Louis, in the Parish of Ste.Thérèse-de-Blainville, known and described as being lot number four hundred forty (440) on the official cadastre for the Parish of Ste.Thérèse-de-Blainville, covering a surface area of approximately fifty-eight arpents; with a house and other buildings erected thereon; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable.\" To be sold at the Terrebonne Division Registry Office, located in Room 106, St.Jerome Court House, on TUESDAY, the ELEVENTH day of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon.Jean-Louis Muir, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, October 31, 1973.54544 Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal { \"L-TOMEPLAN REALTY LIM-No.05-008342-73.-» 11 ITED, a corporation legally ' incorporated under the Statutes of the Province of Ontario, having its head office in the County of York, in the City of Toronto, Province of Ontario, and a branch office in the City of Montreal, Province of Québec, at 6625 Sherbrooke Street East, plaintiff, vs SERGE BEAUDOIN, technician, residing and domiciled at 3405 Evelyn Street, in the City and District of Montreal, defendant.Notice of sale \"An emplacement located in the Parish of Ste.Sophie, Terrebonne Registration Division, known and described as being a part of original lot number three hundred sixty-seven (Pt.367) on the official cadastre for the Parish of Ste.Sophie, designated by the letters A B C D E F G A on a plan prepared by Mr.Hubert Murray, land-surveyor, dated July 24, 1971, under number 4201 and appeneled to a deed of sale executed before Me Jean Moiin, notary, on September 24, 1971, under number 1571 of his minutes, registered at Terrebonne under number 391514, said point A is located at one hundred feet (100') measured in a northwesterly direction, from the point of intersection of the northwest right of way of street 367-63 and street 367-65.The angle B-A-G is a right angle.Bounded on the northwest and on the north by a planned street and part of 367; on the northeast by street 367-65; on the southeast and southwest by part of lot 367. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1978, 105' année, n\" 45 6727 Mesurant cent dix pieds et soixante-dix pieds et deux dixièmes de pied dans ses lignes nord-ouest, vingt-six pieds et deux dixièmes de pied au nord, cent trente-sept pieds et vingt-quatre centièmes de pied et cinquante et un pieds et cinq dixièmes de pied au nord-est, cent trente-quatre pieds au sud-est et soixante-quatre pieds et sept dixièmes de pied au sud-ouest.Contenant une superficie de quinze mille cinq cent cinquante-deux pieds carrés, mesures anglaises et plus ou moins (15,552 pi.ca.).Cette partie de lot est maintenant connue comme étant la subdivision officielle du lot numéro deux cent du lot originaire numéro trois cent soixante-sept (367-200) du cadastre susdit.Toutes les dimensions dans la présente description sont en mesure anglaise.Avec circonstances et dépendances, et l'immeuble dessus érigé, sans exception ni réserve de la part du débiteur.Sujet à toutes servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Le tout tel que représenté sur une description technique portant le numéro 4201 des dossiers de M.Hubert Murray, a.g., ainsi que sur un plan préparé par le même arpenteur, en date du 27 juillet 1971, lesquels demeurent annexés à l'acte de vente, tel que ci-dessus mentionné.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Terrebonne, situé chambre 106, Palais de Justice, 400 rue Laviolette, Saint-Jérôme, MARDI le ONZIÈME jour de DÉCEMBRE 1973 à QUATORZE heures.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Muir.Saint-Jérôme, le 31 octobre 1973.54545-o Errata « O V A C O » (ASSOCIATION COOPERATIVE) Avis de liquidation publié dans l'édition numéro 43 du 27 octobre 1973, page 6282, le titre de l'avis aurait dû se lire: « OVACO » (ASSOCIATION COOPERATIVE) au lieu de: « OVACO ».54433-0 Avis d'introduction de requête publié dans l'édition numéro 43 du 27 octobre 1973, à la page 6217, 2ième ligne, nous aurions dû lire: « .Taux au 100 lbs » a.i lieu de: « .Taux au 10 lbs ».De plus, lOième ligne, nous aurions dû lire: « 50 à/to 99 .80.05 » au lieu de : « 50 à/to 99.$0.50 ».54296-o Measuring one hundred ten and seventy and two tenths feet on its northwest lines, twenty-six and two tenths feet on the north, one hundred thirty-seven and twenty-four hundredths feet and fifty-one and five tenths feet on the northeast, one hundred thirty-four feet on the southeast and sixty-four and seven tenths feet on the southwest.Covering a surface area of fifteen thousand five hundred fifty-two square feet (15,552 sq.ft.), English measure and more or less.This part of lot is now known as being the official subdivision of lot number two hundred of original lot number three hundred sixty-seven (367-200) of the above-mentioned cadastre.All measurements in the present description are English measures.With appurtenances and dependencies, and the building erected thereon, without exception or reservation on the part of the debtor.Subject to all active and passive, apparent or non-apparent servitudes attaching to said immoveable.The whole as appears in a technical description bearing number 4201 in the records of Mr.Hubert Murray, land-surveyor, as well as on a plan prepared by the same surveyor, dated July 27, 1971, which remain appended to the deed of sale, as mentioned above.\" To be sold at the Terrebonne Registration Division Office, located in Room 106, at the Court House, 400 Laviolette Street, St.Jérôme, on TUESDAY, the ELEVENTH day of DECEMBER, 1973, at TWO o'clock in the afternoon.Jean-Louis Muir, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, October 31, 1973.54545 Errata \"O VAC O\" (ASSOCIATION COOPERATIVE) In the winding-up notice published on page 6282 of issue number 43, dated October 27, 1973, the title of the notice should have read : \"OVACO\" (ASSOCIATION COOPERATIVE) instead of: \"OVACO\".54433-0 Notice of submission of application published in number 43, dated October 27, 1973, on page 6217.2nd line, for: \".Rates per 10 pounds\", please read: \".Rates per 100 pounds\".Moreover, on the 10th line, for \"50 à/to 99.$0.50\", please read : \"50 alto 99.$0.05\".54206-o 6728 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1973.Vol.105.No.45 INDEX No 45 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ARRÊTÉ EN CONSEIL ORDER IN COUNCIL 3847 \u2014 Protestante St-Francis (Ancien nom: municipalité scolaire de St.Francis).6720 3847 \u2014 St.Francis Protestant (Former name: School Municipality of St.Francis).6720 ASSEMBLÉE NATIONALE NATIONAL ASSEMBLY Presentation of private bills.6706 Présentation de projets de loi privés.6706 ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Club coopératif de consommation des Bois-Francs (Formation).6682 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICE Fabrique de la paroisse de l'Assomption de Maniwaki (La) (Const.).0096 Fabrique of the parish of the Assomption of Maniwaki (The) (Inc.).6696 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANCE OF NAME ACT Accordés: Granted: Basque, David Thomas.6677 Cardinal, Robert.6677 Elane, Marsha.6677 Guilmet, Joseph René Gaston.6678 McLean, Paul Emile Frederic.6678 Paquin, Y van.6678 Raffan, Katherine April.6678 Richardson, Mary Beatrice Betty Ann.6678 Roessler, Steven Robert.6678 Rothstein, Saul.6679 Strasser, Steven Zygmunt.6679 Taite, Clifford.6679 Demandes: Applications: Boulianne, Marcel.6676 Cantin, Andréa.6675 Chapates, John Anthony.6676 Chapates, Walter Michael.6675 Couture, Diane.6675 Czepaiies.Brenislaus.6676 Czepaitis, Anthony.6675 Fournier, Daniel.6677 Kirschenzaft, Abraham.6674 Mouawad.Rachid Maurice.6677 Papamichalakis, Nicholas.6676 Smith, Anne Morrine.6676 Verret, Ernest.6675 CAISSES D.ÉPARGNE SAVINGS AND COMMISSION COMMISSION ET DE CREDIT CREDIT UNIONS
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.