Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 24 novembre 1973, Partie 1 samedi 24 (no 47)
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES QUÉBEC OFFICIAL « GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° 17 6933 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce.afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Quebec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai PublMer 6934 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2A, 1973, Vol.105, No.A7 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, 820; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10._ N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dube.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion : 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20; from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité Parlementaire, Québec GlA 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call : Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GlA 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° i7 6935 1 AVIS JURIDIQUES\tJURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies\tCompanies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.R.V.INC.ABBOTT REALTIES LTD.ACADEMIE DE MUSIQUE DE VILLE DE LAVAL AGENCES A.L.DU QUEBEC INC.LES AGENCES EMPIRE COMPAGNIE LIMITEE .RAYMOND ALARIE.ALBATROS GOLD MINES LTD.ALBORO INC.ALBRIAN INVESTMENTS LIMITED.AL-CA INDUSTRIES LTD.ALCA UPHOLSTERING AND BEDDING INC.ALDO & ROSY LTEE.ALEMAN CORP.ALEXANDREX INC.J.M.ALLARD CONSTRUCTION LTEE AMERICAN AUTORAMA LTD.AMEUBLEMENTS MAISONNEUVE INC.ANCI.O AMUSEMENTS INC.ANTIQUE FAIR INC.ANTON & BOLDUC INC.ARISTOTELIS VALAORITIS LEFKADIAN SOCIETY OF MONTREAL.ARRELO INC.ARRIN CURLEY LTEE.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1969 inci., 1972 et/and 1973 Laval.1972 et/and 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1962, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Brossard.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1969 à/to 1973 incl.St-Léonard.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.St-Léonard.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Anjou.1964, 1969 à/to 1973incl.Montreal.1961, 1964, 1965, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal .1969.1970 et/and 1973 Montréal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 inci.Montréal.1969, 1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl. 6936 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 Nom de la compagnie Name of the company LES ARROSEURS BLAINVILLE INC.ARROW PRODUCTS CANADA LTD.ARTAPIS INC.ARTEC INTERNATIONAL INC.ARTEFACT INC.ARTISTIC NOVELTY MFG.CO.LTD.ARTON ENTERPRISES LTD.ARTS GRAVURE INC.ARWEPIWIN FISH & GAME CLUB.ASBER CORP.ASBES-DUSSO INC.(LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) ASBESTOS BOULEVARD AUTO LIMITED.ASHLEY'S (ST.JAMES) LTD.L'ASPHALTE GILLES BOISVERT INC.ASPHALTE RIVE SUD INC.THE ASSEMBLY THEATRE.ASSOCIATED PACKERS LIMITED .ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS D'AVIONS EXPERIMENTAUX DE QUEBEC INC.L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN POSAGE DE TAPIS DU QUEBEC INC.ASSOCIATION FEDERATIVE DES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (A.F.E.U.S.) ASSOCIATION G.T.I.L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS APHASIQUES INC.ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DES ECOLES EMARD-GIRARD-LANGLOIS, INC.ASSOCIATION DES PROTHESISTES &.ORTHOTISTES DU QUEBEC.L'ASSOCIATION DES RESIDENTS DE PLACE BEI.LERIVE.L'ASSOCIATION DE THETFORD MINES POUR LES ENFANTS ARRIERES.ASSOCIATION DES VENDEURS DE PIECES D'AUTOS USAGEES (AVPAU) INC.ASSURANCES LETOURNEAU INC.ASTER INVESTMENT CO.LTD.ASTERIA CAFE INC.ASTIR BOOK STORE INC.ASTOR LAND INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Ste-Thérése-de-Blainville 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Greenfield Park.1968 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.194S à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Asbestos.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Henri-de-Mascouche 1971 à/to 1973 incl.Brossard .1968 à/to 1973 incl.Montreal.196S.1969, 1971 à/lo 1973 incl.Dorval.1972 et/and 1973 L'Ancienne-Lorette.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1960 à/to 1973 incl.Québec.1966, 1969 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield .1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.Thel.ford-Mincs.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 inc!.Québec.1972 et/and 1973 Pointe-Claire.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1962, 1963, 1964, 1968, 1070 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 47 6937 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1971 a/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Outremont.1969 a/to 1973 incl.Montréal.1964, 1965 a/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Slianinigar.1970 à/to 1973 ir.cl.Pointe-Claire.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Cl.àteauguay.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1963.1964,1965.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 ir.cl.Montreal .1969 i/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973 Châteauguay Centre.1972, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Dorval.1965, 1968 à/to 1973 incl.Nicolet.1946.1962 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Drummondville.1970 à/to 1973 incl.Greenfield Park.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1962, 1964 à/to 1973 incl.Lévis.1970 à/to 1973 incl.St-Michel.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à to 1973 incl.Montréal.1970 à.to 1973 incl.G ran by.1952, 1959.1960, 1961, 1963, 1967.1970 à/to 1973 inc).Montréal.1966 à/to 1973 Incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 ASTORIA G \\RAGE (1968) LTD.ATACAMA INDUSTRIES LIMITED.ATELIER D'ART ET VITRAUX PIERRE OSTERRATH INC.L'ATELIER DE CHOREGRAPHIE CANADIENNE INC.ATELIERS D'ART DE FRANCE LTEE.LES ATELIERS ST-MARC LIMITEE.ATELIERS DE VITRAUX D'ART LTEE.ATHENIAN MOTION PICTURES LTD.ATLANTIS ENTERPRISES LTD .ATLANTIS FISH MARKET INC.ATLAS CAR RENTAL INC.ATLAS FURNITURE SALES INC.ATLAS LUMBER CO.LTD.ATOMIC CLEANERS & DISTRIBUTORS LTD.ATWATER AUTO BODY INC.AU CAPRICE BAR-B.Q INC.AUBERGE ST-JEAN BAPTISTE INC.AUDART PUBLISHING CORP.AUTO (HOLDING) LTEE-LTD.AUTO MOTION SPEED SHOP INC.LES AUTOBUS DE L'OUEST INC.LES AUTOBUS DE LA RIVE SUD LTEE.AUTODROME TROIS-RIVIERES LTEE.LES AUTOMOBILES MANIC INC.AUTOMOTIVE INVESTMENT CORPORATION.AUTOSKI DISTRIBUTION INC.AUTO-VENTE ST-MICHEL INC.AVEC INC.AVEN INC.AVERY LTEE.AVIRON AUTO LEASING CORP.GEORGES AVLON CLOTHING CO.LTD.AVRUM INVESTMENTS INC.AZTEC IRON CORPORATION. 6938 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.17 Nom de la compagnie Name of the company B & B HOLDINGS & REAL ESTATE INC.B.B.TAXI LTD.B B V CONSTRUCTION INC.BCD INC.B.COMMS INC.B D R CONSTRUCTION INC.B.R.L.INVESTMENT CORPORATION LTD.B.S.L.DESING LTD.BAMCO INDUSTRIES LTD.BATIMAT LTEE.BAYRUT OUTFITTING INC.BEACON MINING COMPANY LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) BEAR AUTOMOTIVE SAFETY SERVICE CENTRE LIMITED BEARON ENTERPRISES INC.BEAUCE EXCAVATION INC.J.BELANGER COURTIERS D'ASSURANCES INC.BERTRAND, BOUCHARD, VIAU INC.GEORGES OMER BIBEAU INC.BOSTON BAY MINES LIMITED.MARC BOULANGER ASSURANCE INC.BOULET AUTO ELECTRIC INC.C.B.T.REALTIES INC.C.& C.CONSTRUCTION INC.C.K.C.M.HOLDINGS LIMITED.C.J.R.MINING LIMITED.C.& L.LUMBER INC.CAM DRYWALL INC.CAFE EL PASO (1966) LTEE.CAMP BNAI BRITH INC.CANADIAN ATHLETIC SUPPLIES LTD.B.C.CARON INC.CAVANAL LIMITED.CAYBRIDGE RESOURCES LTD.CEASAR'S PALACE (1969) INC.CEDRA CONSTRUCTIONS INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Shawinigan.1970 à/to 1973 incl.Québec.1971,1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Bourlamaque.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Lachine.1972, 1973 St-Georges.1970 à/to 1973 incl.Verdun.1971 à/to 1973 incl.Lasalle.1970 à/to 1973 incl.Sorel.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.St-Miche!.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Lasalle.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1967 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.La Sarre.1964.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Lachine.1966 a/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973.105' année, n° 17 6939 Nom de la compagnie Name of the company CENTENNIAL AUTOMATIC VENDING CO.LTD.CENTRAL ASBESTOS MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) CENTRE D'ACCUEIL POUR ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES DE ST-EUSTACHE INC.CENTRE AQUATIQUE REGIONAL DE TROIS-RIVIERES INC.LE CENTRE D'ART R.U.INC.CENTRE D'ASTROLOGIE ZODIAQUE INC.CENTRE D'EQUIPEMENT DE BUREAU O.F.C.INC.CENTRE MUSICAL ET CULTUREL DE CHOMEDEY.CENTRE RECREATIF DE ST-PI ERRE INC.LES CHALETS BASSO INC.CHALIFOUR & FRERES LIMITEE.J.M.CHALIFOUX LTEE.EDGAR CHARBONNEAU (BONAVENTURE) INC.CHART BAY EXPLORATIONS LIMITED.CHAUVEAU ARTS 4 TRADITIONS INC.CHEZ CLEMENCE INC.CHEZ FADA INC.CHOMEDEY GO-KART INC.C1E DE GESTION ST-ALEXANDRE INC.CIE NATIONALE D'ASPIRATEURS LTEE.LA CIE DE PLACEMENTS LEMERILLON LIMITEE.CITIES AND TOWNS SUPPLIERS LIMITED.CIVIC LAND AND DEVELOPMENT CORP.CILLES CLAIROUX INC.LE CLAN, CAFE-ETUDIANT.EUGENE CLAVET INC.CLEVELAND ENTERPRISES INC.PATRICK CLICHE INC.ROCK CLIFF HOTEL INC.CLOE CORPORATION.YVES CLOUTIER INC.CLOVER LEAF LAND CORPORATION.CLOVER VALLEY DEVELOPMENTS INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Laval.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1964.1971 à/to 1973 incl.St-Eustache.1972 et/and 1973 Trois-Rivières.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Chomedey.1965, 1968 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.St-Sulpice.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Gatineau.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Lasalle.1970 à/to 1973 incl.Anjou.1965.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal .1964, 1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Verdun.1968 à/to 1973 incl.St-C.eorgc.-.1970 à/to 1973 incl.Stanstead.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Montreal.1958, 1959.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl. 6940 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105.No.17 Nom de la compagnie Name of the company CLUB D'ASTRONOMIE DRUMMONDVILLE INC.CLUB AUTO-NEIGE DE L'AVENIR INC.CLUB AUTO-NEIC.E CHAMPLAIN INC.CLUB AUTO-NEICE PONT-ROUC.E INC.CLUB DE BASE-BALL CONCORDE LAVAL.CLUB DE C.A P.CORBEAU.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE DU LAC HA HA INC.LE CLUB DE CHASSE ET PECHE MONT-CARMEL.CLUB DE CHASSE SOUMANDE.CLUB DES CHUTES DE CHARETTE INC.LE CLUB DE CURLING JACQUES-CARTIER.CLUB DE GOLF LES ARPENTS VERTS INC.CLUB DE HOCKEY MONTMACNY INC.CLUB LIONS CLERMONT-LA MALBAIE-POINTE-AU-PIC (MURRAY BAY) INC.CLUB MASKIMO.CLUB MOTO-NF.IGE NEUVILLE INC.CLUB NAUTIQUE DE L'ILE GOYER INC.CLUB OASIS DES AVEUGLES DE SHERBROOKE INC.CLUB OPTIMISTE VAL MARTIN INC.LE CLUB QUEVILLON INC.CLUB DE REFORME DE MONTREAL.LE CLUB SOCIAL ET ARTISTIQUE DE QUEBEC INC.CLUB SOCIAL LES AVENTURIERS INC.LE CLUB SOCIAL DES « MOOSE » DE PORT-ALFRED INC.CLUB SOCIAL ET SPORTIF DE L'AVENIR INC.CLUB SPORTIF ALBO INC.CLUB SPORTIF ET CHAMPETRE NAPIERVILLE INC.LE CLUB DES SPORTS DE PORT-ALFRED INC.CLUB DES TREMBLES INC.COLLISION APPRAISAL SERVICES (QUEBEC) LIMITED.COMBINED INVESTMENTS LTD.COMEAU AUTOMOBILE INC.LA COMPAGNIE CHOMODU INC.COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EXPANSION COMMERCIALE LTEE.Adresse Rapports non produits Addrest Returns not filed Drummondville.1966 a/to 1973 incl.Drummondville.1970 à/to 1973 incl.I^moyne.1970 à/lo 1973 incl.Pont-Rouge.1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 a/to 1973 incl.Gatineau.19C-» a/to 1973 incl.Chiroutimi.1958 alio 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Mont-Carmel.1950 à/to 1973 incl.Québec.1953 à/to 1973 incl.Charette.1972 et/and 1973 Sillery.1970 à/to 1973 incl.Terrebonne.1971 à/to 1973 incl.Montmagny.1972 et/and 1973 La Malbr-.ie.1972 ct/and 1973 St-Paulin.1964 à/lo 1073 incl.Neuville.1970.1971 et'and 1973 Chamblv.1966, 1967.1968.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Laval.1968.1970 à/to 1973 incl.Lcbel-sur-Qiiévillon.1007 à/to 1973 incl.Montreal.1938.1939,1971.1972 ot/and 1973 Quebec.1961 à/to 1973 incl.Shannon.1972 ct/and 1973 Port-A'.fred.1966 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Napierville.1971 à/to 1973 incl.Bajrotville.1965 à/to 1973 incl.Alma.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.St.-Eustache.1971 à/to 1973 inel.Iberville.1968.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, »\" 47 6941 Nom de la compagnie .Vame of the company LA COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES EAUX DU QUEBEC.LES COMPAGNONS DES METIERS D'ART INC.COMPTOIR AGRICOLE DE ST-ELOI INC.CONCORDIA EXPRESS INC.LES CONSTRUCTIONS ET IMMEUBLES BERNARD BOUCHER INC.LES CONSTRUCTIONS SAINT-JEAN LIMITEE.LA CORPORATION DES CITOYENS CANADIENS D'ASCENDANCE FRANÇAISE LTEE.LA CORPORATION D'EXPANSION L'APEX INC.CORPORATION DES ROUTIERS DU QUEBEC INC.COSMOX CORPORATION LIMITED.COVA CATERING INC.LES CREATIONS CLAUDY INC.CREATIVE ARTS CORPORATION.CREE INDIAN CENTER OF CHIBOUGAMAU.D.B.L.C.CONSTRUCTION INC.D.B.T.INVESTMENT CORPORATION.D.C.ELECTRIC INC.D.H.PAVAGE D'ASPHALTE INC.ALBERT DAIGLE & FILS INC.DANNY'S BAR INC.ALEX DANSEREAU & CIE LTEE.DECELLES AVENUE HOLDINGS LTD.LES DEVELOPPEMENTS VAL-ALAIN INC.DISTRIBUTEURS AUTOMOTIVE MOBILE INDEPENDANT INC LES DISTRIBUTIONS F.C.INC.DOANE & DOANE INC.DOMAINE DU BOIS DE MONTREAL LTD.DOMIRO LTEE.DYNAMIQUE DE RECHERCHE PERSONNELLE DU QUEBEC INC.EDMOR KNITTING MILLS LTD.EL TORERO STEAK HOUSE INC.ELITE ENTERPRISES LIMITED.THE ELIZABETH LOW FUND INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Eloi.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-David-de-L'Aube- 1972 et/and 1973 rivière.St-Jean.1971 à/to 1973 incl.Aylmer.1970 à/to 1073 incl.Québec.1965.1967,1969,1970, 1972 et/and 1973 St-Léonard.1969, 1970, 1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Chirougamau.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Buckingham.1971 à/to 1973 incl.Laval.1966 à/to 1973 incl.Terrebonne.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Val-Alain.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Noranda.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1964 à/to 1973 incl. 6942 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.47 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1959, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1965 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Neufchâtel.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1965, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1972, 1973 Beauharnois.1972.1973 Gatineau.1966 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1971 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.Ville Vanier.1972, 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à.'to 1973 incl.Montreal.1965.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Anjou.1969 à/to 1973 incl.Québec.1973 Montréal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Berthier.1971 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts .1961 à/to 1973 incl.St-Lambert.1973 Châteaugugy-Centre .1968 à/to 1973 incl.Châteauguay-Centre .1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Giffard.1966, 1972, 1973 ELIZABETH REALTY LTD.ELLIOTT INVESTMENT INC.ELM INVESTMENT CORP.ELMOUNT DEVELOPMENTS LTD.ELNOR INC.ELPAC ELECTRONICS LTD.ELRAY INC.EMBASSY LEISURE WEAR INC., EMBLA LIMITED.EMMA GOLD MINES LIMITED (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) EMMAR AUTOMOBILES INC.ENCEE LIMITED.ENGO REALTIES INC.EN-OLA EXPLORATIONS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) LES ENTREPRISES BUREAU & CHOUINARD LTEE.LES ENTREPRISES ELMEC INC.LES ENTREPRISES GATINEAU INC.LES ENTREPRISES LECABRIE LTEE.LES ENTREPRISES MARCOTTE INC.LES ENTREPRISES MAREDO LTEE.LES ENTREPRISES ROSACO LTEE.EQUIPEMENT DE RESTAURANT INTERNATIONAL INC.EXPOSAL APPRAISAL INC.FASHION GIRL OF MONTREAL INC.FEDERATION DE LAWN-TENNIS DU QUEBEC.FER ARTISTIQUE INC.NOEL FERLAND & ASSOCIES INC.FERMES AVICOLES UNIES LTEE.LA FERRONNERIE D'ART INC.FESTIVAL DES NEIGES LAURENTIEN.FINCO INCORPOREE.LES FLIBUSTIERS ET BATELIERES DE CHATEAUGUAY-CENTRE FRASER, GRAF, BARGETZI INC.G.M.ENTERPRISES LTD.MICHEL GAGNON LTEE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 47 6943 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Chicoutimi.1961 à/to 1965 incl.1968 à/to 1973 incl.Victoriaville.1966.1967.1969, 1971 à/to 1973 incl.Sicotte.1971 à/to 1973 incl.Gatineau.1972, 1973 Gatineau.1968 à/to 1973 incl.St-Janvier.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1969, 1972, 1973 Montreal.1971 à,to 1973 incl.St-Paul-L'Ermite.1964 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1967 à/to 1973 incl.Québec.1966, 1972, 1973 La Conception.1971 à/to 1973 incl.Laval.1967 à/to 1973 incl.Verdun.1961 à/to 1966 incl., 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1971,1972.1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Maniwaki.1965 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à/to 1973 incl.St-Eustaclic.1962, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal .1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Trois-Riviêres.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Brossard.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Ville Lasalle.1964, 1971 à/to 1973 incl.Alma.1972, 1973 GARAGE ALGER INC.LA GARDE PAROISSIALE STE-FAMILLE INC.GATILABEL INC.GATINEAU BACKHOE INC.GATINEAU TEXTILE LTD.GAL GAUTHIER TRANS-SPORT INC.GAVIN REALTY CORP.GAYTIME CASUALS INC.WILSON GELINAS A FRERES INC.GEN-AUTO SHIPPERS (QUEBEC) LIMITED GENI INC.GENTILLY ROAD HOUSING CORP.GEORGE GENERAL AUTO REPAIRS INC.GERIDEN INC.MARC GINGRAS INC.GINGRAS, REID, GAUDREAU INC.GIRO CONSTRUCTION LTEE.GLASS AND WALL DECOR (MONTREAL) INC.AL.GOUDREAU CARTAGE LTD.GRAND PRIX MOTO-NEIGE STE-JOVITE MONT-TREMBLANT INC.CUILDE ASTRORAMA LTEE.H.B.D.ENTERPRISES INC.LES HABITATIONS EMMANUEL LIMITEE HABITATIONS LOUIS FRECHETTE INC____ HAND ASSEMBLING A PACKAGING LTD.HAYES EASTERN TRUCK SALES CO.LTD.HELLENIC FISHERIES LTD.HERB NOVICK SALES CORP.HOME WORK ASSEMBLING LIMITED.HOTEL ST-MAURICE INCORPOREE.THE HUDSON BAY SYNDICATE INC.HYDRA LUBE INC.I.J.R.TRADING INC.LES IMMEUBLES ALEPIN LTEE.LES IMMEUBLES BANC DE SABLE INC. 6914 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 21.1973.Vol.105.No.17 Nom de la compagnie Name of the company LES IMMEUBLES BASLOR INC.LES IMMEUBLES DU BASSIN DE CHAMBLY INC.LES IMMEUBLES GERMAIN POUI.IN LTEE.IMMEUBLES LAV INC.LES IMMEUBLES MARCOTTE LTEE.IMPRIMERIE MARCHAND INC.INDUSTRIES GENERALES DU QUEBEC LTEE.LES INDUSTRIES GEYSER INC.LES INDUSTRIES L.CATIEN LTD.INDUSTRIES MARCO INC.LES INDUSTRIES THERMO LTEE.INSTANT COPY CENTRES INC.INSTITUT DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DE QUEBEC L'INSTITUT DES ARTS DE ST-FELICIEN.INTERNATIONAL LAND INVESTMENTS CORP.INTERNATIONAL RAY'GUY CO.LTD.INTERPROVINCIAL DEVELOPMENT CO.LTD.ITALSWISS OVERSEAS INVESTMENT INC.J.G.CONSTRUCTION INC.JERO ENTERPRISES OF CANADA LIMITED.LA JEUNE CHAMBRE DE PIERREVILLE.LA JEUNE CHAMBRE DE ST-ALEXIS-DES-MONTS.JO-AL INVESTMENTS LTD.IODOIN & JETTE INC.K.J.APARTMENTS INC.K.TRANSPORT CENTER LTD.KAR ENTERPRISES LTD.KAYSER-ROTH INDUSTRIES LIMITED.KIRAKO LTD.THE KIWANIS CLUB OF LAKE ST-LOUIS POINTE-CLAIRE INC.KOT-N-AT INCORPORATED.\"\".L.& R.ELECTRONICS INC.LAITERIE GATINEAU LTEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Jérôine.1966.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Duvernay.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1970.1972, 1973 St-Fclicien.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1965.1966.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Beauhnrnoij.1962.1963.1965 à/to 1973 incl.Marievillo.1961.1966.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970.1972,1973 Montréal.1972.1973 Ste-Foy.1967.1972,1973 St-Félicien.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Rimouski.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1966.196S à/to 1973 incl.Laval.1965 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1963 à/to 1973 incl.Pierreville.1970 à/to 1973 incl.St-Alexis.1967, 1970 à/to 1973 incl.Mont-Royal.1960.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1953.1966.1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973 Gatineau.1965, 1967.1970.1972.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9.L novembre 1973, 105' année, n° 17 6945 Nom de la compagnie Name of the company lake george development inc.lake otter uranium mines ltd.(no personal liability; lakeshore coffee house association.i.akeshop.e construction company\" limited.lakeshore garden supplies inc.lakeview athletic & social club of laval west inc.lamontagne excavation inc.gilles lapointe auto location ltee.lariviere enterprises ltd.c.larochelle inc.paul emile larouche inc.laurel ladies wear inc.laurentian horsemen inc.laurion & frere inc.lauvacinc.laval sports inc.lave auto leclerc inc.roger leblanc (helicoptere-aviation) ltee.lee's fine foods ltd.librairie bas-laurentienne inc.librairie du trigone inc.la ligue nationale de baseball junior inc.la ligue des proprietaires et des contribuables de ste-marguerite inc.claude limoges inc.lo-bar ranch inc.gilles locas inc.loisirs aubergine inc.les loisirs de chibougamau inc.les loisirs de ste-cecile-de-levrard inc.loisirs tambour battant.longueuil investment incorporated.lowell realty & investment inc.m.c.r.performance research inc.m.f.paint inc.m.j.c.distribution inc.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.19C4, 1965, 1967 à'to 1973 incl.Montreal.1957,1972,1973 Beaconsfield.1966 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1967 à/to 1973 incl.Vaudreuil.1967 à/to 1973 incl.Laval.1963 à/to 1973 incl.Anjou.1972, 1973 St-Pierre-de-Sorel.1966 à/tr.1968 inc!., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1967 à/to 1973 incl.Delisle.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Lachute.1971 à/to 1973 incl.Joliette.1970 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Lac Etchemin.1972.1973 St-Jérôme.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Mont-Joli.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Marguerite du Lac 1965 à/to 1973 incl.Masson.Ste-Thérèse.1972, 1973.Châtcauguay.1971 à/to 1973 incl.St-Jerome.1969 à/ to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Chibougamau.1966, 1970 à/to 1973 incl.Ste-Cécile-de-Levrard.1972, 1973 Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970, 1971, 1973 Montreal.1960 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl. 694fi QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1073, Vol.105, No.1,7 Nom de la compagnie Name of the company MACHINERIE BE-AL INC.LA MAISON DU CHOMEUR DE ST-HENRI INC.MAISONNEUVE SPORTSMEN'S SOCIAL ASSOCIATION INC.LES MAITRES NETTOYEURS DU QUEBEC INC.MAJOR LAURENT MINES LTD.LES MAJORETTES LES QUEBECOISES.MALCOURT INC.MALDA LTD.MALO CORPORATE INVESTMENTS (QUE) LTD.MALTAIS & TREMBLAY INC.MANARA INC.MANIFOLD ENTERPRISES INC.MANO CONSTRUCTION INC.LE MANOIR MONTREAL.MANOIR DES ORMES INC.MANOIR ST-PHILIPPE INC.MANSU MANAGEMENT.P.P.MANTHA INC.MANTRYX LTD .MAPLE ENTERPRISES LTD.MAPLE REALTY CORP.MARADO CONSTRUCTION INC.MARAL HOLDINGS INC.MARAL HOLDINGS INC.MARANCO LIMITEE.MARAYNARD LTEE.MARBEC STEEL CORPORATION.MARBLE & STONE PRODUCTS LIMITED.MARCEL MUSIC TORE INC.MARCO AUTOMOBILES INC.MARCO INVESTMENT CORPORATION.CLEMENT MASSIE INC.GEORGES MATTHIEU AUTO CENTER INC.MENUISERIE BLAIS & FILS INC.MERCHANTS OVERSEAS CORPORATION.MESSAGERIES LAVAL INC.METRICLAB INC.Adresse Rapports non produits Addreiê Return! not filed Ste-Foy.1972,1973 Montréal.1971 a/to 1973 incl.Montreal.1964 a/to 1973 incl.St-Jean.1972,1973.St-Laurent.1971 à/to 1973 incl.Oaspe.1972, 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1955.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Chicoutimi .1963, 1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Lebcl-Eur-Quévillon.1968 à/to 1973 incl.Dorval.1959, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Thérése.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-Georges.1967, 1968, 1972.1973 St-Philippe.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Laurentides.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Dorval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Alma.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1969 à/to 1973 incl.Verdun.] 968 à/to 1973 incl.Buckingham.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Pointe-aux-Trembles- 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Lemoyne.1968 à/to 1973 incl.Dorval.1970 à/to 1973 incl.Laval.1972, 1973 Greenfield Park.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DO QUÉBEC, SA novembre 1973, 105' année, n° A7 6947 Nom de la compagnie Name of the company METROPOLITAN HOTEL MANAGEMENT INC.METROPOLITAN LAND CO.LTD.MICRO ART INC.MIRACLE ART FURNITURE CREATIONS INC.MONOLEA BEACH BUNGALOWS INC.MONSIEUR ELEGANT INC.MONTREAL MOULD MAKERS LIMITED.MONTREAL OIL TANK SERVICES LTD.MONTREAL ROYAL REGIMENT OF CANADIAN ARTILLERY \"NUMBERS ONE\" CLUB.MOORHEAD ISLAND LODGE LIMITED.MOTEL L'EMERILLON INC.THE MURRAY BAY MOTOR CO.LTD.NEGRO CITIZENSHIP ASSOCIATION INC.NETTOYEUR LEMAY INC.NETTOYEURS WELLINGTON INC.NO MAN'S LAND YOUTH CENTER.NORBRITE INC.NORGATE CLINICAL LABORATORIES LTD.NORTH EAST AUTOMOTIVE INDUSTRIES LTD.NORTH END RESIDENTIAL CENTRE INC.LE NOUVEAU BOTTIN TELEPHONIQUE ITALIEN LTEE.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ST-GERMAIN INC.OGILVY & MATHER (QUEBEC) LIMITED.OLD ALFAMA RESTAURANT INC.OLD ATHENS RESTAURANT INC.OPTICA ST-CATHERINE INC.ORAK SERVICE CENTER LTD.PAN CANADIAN IMPORT AND EXPORT INC.LES PARACHUTISTES DU SAGUENAY LAC ST-JEAN INC.RENE PARE INC.PARK-CREST CLOTHES INC.CHANTAL PARY INC.PAVAGE MARCEL MORIN INC.PAVILLON CLAUDE INC.A.PELLERIN INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1065 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.La Pocatière.1971) à/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Jerome.1966,1967,1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Allumette Island.1965, 1966, 1971 à/to 1973 incl.Pointe-du-Lac.1966.1971 à/to 1973 incl.St-Michel.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Verdun.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Lachine.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Rimouski.1958 à/to 1964 inlc.1966 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Anjou.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Alma.1969 à/to 1973 incl.Shawinigan.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl, Montreal.1971 à/to 1973 incl.L'Ancienne Lorette.1967 à/to 1973 incl.Gatineau.1969, 1971 à/to 1973 incl.Mont Rolland.1964 à/to 1973 incl. 6948 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.17 Nom de la compagnie Name of the company PEM ART ENTERPRISES INC.PETER & STEVE'S SNACK BAR INC.JAN PICK TRICOT COMPANY LTD.PINCOURT CIVIC LEAGUE INC.PINK SHOWER AND BATH MANUFACTURING COMPANY LIMITED LA PIPE BEACH CLUB INC.PISCINES GIBRALTAR INC.PLACEMENTS LA BARRE LTEE.LES PLACEMENTS CITEMONT INC.PLACEMENTS RAY-LAU INC.LES PLACEMENTS RAYMOND BREAULT LTEE.PLANNEO SITES INC.PLAZA SNACK BAR LTEE.POINTE CLAIRE MEDICAL CENTRE INC.POINTE CLAIRE REALTY LIMITED.LA POISSONNERIE DU PECHEUR JOS PAQUET INC.POLBER LTEE.LES PRODUCTIONS L & C INC.LES PROPRIETAIRES DE CHALETS DU LAC CAVEN INC.LES PUBLICATIONS HOCKEY QUEBEC INC.PYRAMID AUTOMOTIVE SALES LTD.QUALITY PAD INC.QUALITY PANTS INC.QUEBEC ASSOCIATION FOR THE MENTALLY RETARDED QUEBEC CAULKING & SEALANTS LTD.QUEBEC CLAY MINING LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) QUILL-O-RAMA LTEE.R.C.H.VIRGINIA LTD.R.G.ASPHALTE ET CONSTRUCTION INC.RANCH CANADIANA INC.RANNANA INVESTMENT CORP.REGENT FINANCE CORPORATION LIMITED.REGIS ANTIQUAIRE INC.RENT-ALL CENTRE LTD.REPRODUCTIONS ANTIQUES MONTREAL INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1968.1970 à/to 1973incl.Pincourt.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Alma.1972, 1973.Québec.1967 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-Léonard.1972.1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.1965 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Westmount.1969, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Gilles.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Léonard.1968 à/to 1973 incl.Chapais.1972, 1973 Montréal.1970, 1972, 1973.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1971 incl.1973 Québec.1966 à/to 1973 incl.Warwick.1962.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Magog.1972, 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 34 novembre 1973, 105' année, n\" 47 6949 Nom de la compagnie Name of the company RESIDENCE STE-CATHERINE INC.LES RESIDENCES CHAMPS ELYSEE LTEE.RESTAURANT MANON INC.RESTAURANT MI-CHEMIN LTEE.LE CHEMIN R.G.INC.RESTAURANT ST-GEORGES INC.LES RESTAURANTS MARIE-CLAIRE INC.ROBIN CLEANERS LTD.ROCKY REALTIES LTD.CH.RODIER CIE LTEE.ROMAN FUR FASHIONS INC.ROULOTTES METROPOLE INC.CLAUDE ROY ET FRERES INC.LES RUCHERS C.ST-LOUIS LTEE.S.B.LIMITEE.8T-CLOUD CONSTRUCTION LTEE.ST-SAUVEUR TENNIS CLUB INC.STE-GENEVIEVE GARDENS HOMEOWNERS' ASSOCIATION SAFARI AUTOMOBILE LIMITEE.SAKARIS BROTHERS FRUIT MARKET INC.SALON CLAUDETTE MADORE INC.SALON ELISE INC.SALON INTERNATIONAL DE LA MODE ET DE LA BEAUTE INC.SALON LAPORTE INC.GEORGES SASSEVILLE & FILS LTEE.GERARD SAUVAGEAU CONSTRUCTION INC.LA SEIGNEURIE GALERIE D'ART INC.SERVICE AUTO INC.SERVICE GENERAL D'ADMINISTRATION M.T.INC.SEYMOUR ELIESEN SALES AGENCIES LTD.SHAMROCK FISH LTD.SIMARD LAVEUSE SERVICE INC.SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DE RIVIERE-DU-LOUP INC.LA SOCIETE DES BATEAUX-MOUCHES INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Contrecoeur.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1966, 1967.1969, 1971 à/to 1973 incl.Lery.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Mont^Laurier.1971 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.CôteSt-Luc.1964 à/to 1973 incl.St-Sauveur-des-Monts .1961.1962, 1967 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1964 incl.1966 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.St-Eugène.1964 à/to 1973 incl.Ville-St-Michel.1971 à/to 1973 incl.Boucherville.1970 à/to 1973 incl.Baie-Comeau.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1972.1973 Montreal.1968.197U à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl. 6950 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November H, 1973, Vol.105, No.47 Nom de la compagnie Name of the company SOCIETE CON-AD-GEST INC.SOCIETE DE GESTION CLAN SAVARD INC.LA SOCIETE MALBEC INC.SOCIETE URBAINE DES TRANSPORTS RAPIDES INC.THE SOCIETY OF NURSING ASSISTANTS OF QUEBEC INC.SODEMET INC.SOFINA INC.SOGEMO INC.SOGEROUINC.SOGESINC.SOLEM INC.SOVEREIGN CRUDE OIL & ASPHALT COMPANY LIMITED SMITH REALTIES INC.GERRY SNYDER ENTERPRISES CORP.STATION SERVICE MARCOUX INC.STATION SERVICE ROSEMONT INC.STIRLING INVESTMENT CORP.STYLE TOGS INC.STOBERS LIMITED.S.STOROZUK TRANSPORT LTD.SUPERIOR CLEANERS LTD.SUZANNE MANUFACTURING INC.SWISS PRECISION AUTOMATIC INC.TASCHEREAU ART DECOR INC.TAVERNE REX INCORPOREE.TAVERNE A LA RIVIERE INC.TAYLAN CORPORATION.TECHNI-ART INC.TEL-A-VIV RESTAURANT INC.TERMINAL AVIATION SERVICES INC.THISTLETOWN TRADING (QUEBEC) INC.TOWN & COUNTRY MOTORCYCLE CLUB.TREMBLAY & GERVAIS INC.MARCEL TREPAN 1ER INC.TRIG LIMITED.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Montreal.1968 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1971 à/to 1973 incl.Vanier.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 St-Laurent.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Brossard.1967 à/to 1973 incl.St-Hubert.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Québec.1958, 1965.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1945.1971 à/to 1973 incl.St-Michel.1970,1972,1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.LaBèche.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1970 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1971, 1972, 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1972, 1973 Pierrefonds.1971 à/to 1973 incl.Jonquière.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SI novembre 1973, 10H< année, n° A7 6951 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed TRISTAR COMPANY LIMITED.TRUDY & CLAUDE'S INC.A.R.TURPIN LTEE.1970 à/to 1973 incl.THE TWIN BEAVER MINING COMPANY.(NO PERSONAL LIABILITY) UNION DU LIVRE ET DES ARTS LTEE.UNION TRUNK SALES CORPORATION.UNITED AVIATION SERVICES LIMITED.UNITED CITIZENS OF DORVAL.UNIVRAC INC.ROGER VAILLANT INC.VAL ROYAL MANAGEMENT INC.VALIANT INTERNATIONAL TRADING CORP.VELPA CONSTRUCTION INC.VELRACINC.VIAUVILLE TIRE LTD.VIGICOLTEE.VITRERIE TRANS-QUEBEC INC.WEST END PLAZA INC.WEST-END INVESTMENT COMPANY.WESTMOUNT CATERERS INC.E.WHITE INCORPORATED.WOOD BRIDGE BEACH CLUB.ZENITH FINANCE CORPORATION.Ste-Catherine-d'AIexan-drie-de-Laprairie Laval.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1909 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Dorval.1965 à/to 1973 incl.Shawinigan.1969.1972, 1973 Gatineau.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Hubert.1972, 1973 Joliette.1972, 1973 Montreal.1972, 1973 Hull.1970 à/to 1973 incl.Granby.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Verdun.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1971 à/to 1973 incl.Beaconsfield.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1966 incl., 1969 à/to 1973 incl.54695-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54695-0 Pierre Debjardins, Director of the Companies Serrice.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date ALBERFORD SPORTING CLUB.ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DE ST-AUGUSTIN INC.ASSOCIATION DES CLUBS DE CHASSE ET DE PECHE DE LA MAURICIE Ottawa.25 05 1898 St-Augustin.18 05 967 Trois-Rivières.07 07 1947 6952 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November U, 1973, Vol.106, No.47 Nom de la compagnie Name of the company BELLEVIEW-RAND CLUB INC.BIER CREEK FISH AND GAME CLUB.BROMPTON LAKE FISH & GAME CLUB.CANTON BOYER FISH & GAME ASSOCIATION INC.CLUB L'AVENTURE INC.CLUB BEBE.CLUB BELLES TRUITES INC.CLUB DE C.& P.AU LAC KANIAPISKAU.LE CLUB DE CHASSE ET PECHE CHATEAU BRILLANT INC.LE CLUB DE CHASSE & PECHE LE MONTEUX DE NICOLET.CLUB DE CHASSE & PECHE PIJO.CLUB DE CHASSE ET PECHE SCENIC INC.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE SI-FO INC.CLUB DE CHASSE PROVENCHER.CLUB DE CHASSE SQUAWCAP.CLUB \"CIRCLE\" CLUB.CLUB LES COPAINS INC.CLUB DESIRE INC.CLUB E.O.LARIVIERE.CLUB DES GARDES.CLUB GASPE NORD.CLUB GILBERTE INC.CLUB HA-RO-MA-MA INC.CLUB DE LA HAUTE MONTAGNE.CLUB HORIZON.CLUB IMPERIAL.CLUB ISABEAU INC.CLUB JACQU'CLO INC.CLUB JOYEUX.CLUB KAOSIS KAKIMAT.CLUB DU LAC BLANC.CLUB DU LAC BOISVERT.CLUB DU LAC DES CANARDS HUPPES.CLUB DU LAC CHOATE INC.CLUB DU LAC DES COTE.CLUB DU LAC DESCHENES.CLUB DU LAC FIN.Adresse Incorporation Address Date Sherbrooke.11 02 1964 Maniwaki.14 09 1959 Brompton.16 12 1941 Montreal.10 08 I960 Sept-Iles.05 06 1957 Aima.20 03 1963 Québec.04 12 1962 Chicoutimi.22 10 1963 Perkins.20 07 1970 Nicolet.27 05 1963 Hull.02 11 1965 Bedford.15 08 1958 Cap-de-la-Madeleine____ 19 02 1958 Québec.21 07 1957 Amqui.07 06 1952 Dolbeau.23 06 1958 Matane.27 03 1958 St-Zénon.20 05 1959 Noranda.09 04 1965 Jonquière.14 06 1963 Ste-Anne-des-Monts.02 02 1955 Montréal.04 06 1959 Farnham.29 07 1959 St-Aimé-des-Lacs.08 05 1963 Montréal.03 04 1964 St- Jérôme.03 01 1956 Roberval.22 05 1962 Senneterre.24 09 1959 Girarville.21 07 1964 BaieComeau.16 11 1964 Buckingham.04 06 1949 Mont-Laurier.22 04 1947 Ste-Florence.28 04 1960 Val d'Or.10 10 1959 Bagotville.09 10 1956 Marsoui.22 01 1953 Rivière-du-Loup.09 12 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SA novembre 1973, 105' année, n' A7 6953 Nom de la compagnie Name of the company CLUB DU LAC DES JONCS INC.CLUB DU LAC LAFIOLE.CLUB DU LAC LEON.CLUB LAC LEZARD.CLUB DU LAC A LOUIS.CLUB DU LAC LOUISE.CLUB DU LAC AUX LOUTRES.CLUB DU LAC MARTIN INC.CLUB DU LAC MISERABLE INC.CLUB DU LAC PLAT.CLUB DU LAC DE LA POINTE BRULEE INC.CLUB DU LAC RIMOUSKI.CLUB LAC DE LA RIVIERE DU LOUP.CLUB LAC SOMMET DE MONT-JOLI.CLUB DU LAC SUSANNA.CLUB DU LAC VIOLON.CLUB LACONA INC.CLUB LAFITEAU.CLUB DE LA LANDROCHE INC.CLUB LANGIRO.CLUB LANGIS.CLUB LAPIN BLANC.CLUB LAURENCELLE INC.CLUB LAURIER.CLUB LECOMPTE.CLUB LEGER.CLUB DE LA LIEVRE DE KIAMIKA INC.CLUB LIGNALEAU.CLUB LOLA.CLUB LORETTE .CLUB DES LOUIS INC.CLUB LOUIS LEON.CLUB MACARIBO INC.CLUB MAISON BLANCHE.CLUB MALBO INC.CLUB MANIGO INC.CLUB MANIGOUCHE INC.Adresse Address Incorporation Date Montréal.09 01 1961 Rimouski.26 01 1953 Jonquière.07 06 1945 Montréal.02 06 1964 Anse-St-Jean.04 03 1952 Chicoutimi.29 01 1951 Ste-Anne-de-la-Pocatière 25 02 1948 Québec.09 05 1961 Mont-Laurier.20 02 1958 N.-D.-du-Lac.21 11 1953 Kamouraska.21 01 1959 Rimouski.16 03 1948 St- Pascal.09 07 1952 Mont-Joli.27 05 1953 Bagotville.06 11 1948 Montmagny.23 09 1950 Mistassini.03 10 1961 La Tuque.21 09 1965 Baieville.23 08 1966 St-Honoré.10 04 1963 Sept-Iles.13 04 1965 Trois-Rivières.15 09 1965 Ste-Thérése.13 02 1959 St-Laurent.07 01 1955 Amos.11 07 1952 Les Escoumins.15 06 1965 Kiamika.01 06 1960 Malartic.14 05 1956 Laval.08 06 1965 N.-D.de Lorette.11 06 1952 Cap Rouge.28 04 1961 St-Urbain.30 07 1968 Québec.14 05 1959 St-Coeur-de-Marie.01 10 1964 Laterrière.29 08 1961 Shawinigan.18 02 1959 Dolbeau.27 09 1961 6954 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973.Vol.105, No.il Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date CLUB MARAYNORD INC.\t\t11\t09\t1961 CLUB MARECHAL.\t\t15\t07\t1963 CLUB MARIAN.\t\t30\tM\t1963 CLUB MARIE FRANCE.\t\t20\t09\t1964 CLUB MARISTE.\t\t15\t11\t1951 CLUB MARLENE.\t\t04\t08\t1964 CLUB MARSOUI.\t\t22\tOS\t1963 CLUB MATHIEU.\t\t17\t06\t1950 CLUB MAURICIE INC.\t\t11\t11\t1957 CLUB MAY FLOWER INC.\t\t15\t07\t1959 CLUB McNIDER.\t\t20\t07\t1949 CLUB MECHANIQUE.\t\t25\t06\t1966 CLUB MEILLEUR.\t\t03\t08\t1964 CLUB MERCEDES DES OURS.\t.St-Donat.\t26\t06\t1960 LE CLUB MERVEILLE.\t\t20\t07\t1965 CLUB MICHEL.\t\t.09\t00\t1953 CLUB DU MILLAGE VINGT-NEUF.\t.Val d'Or.\t23\t08\t1948 CLUB MILLECHARME INC.\t\t23\t01\t1959 CLUB MISTASSIBI.\t\t20\t01\t1954 CLUB MISTOUK.\t.Ville Mont-Royal.\t30\t03\t1960 CLUB DU MONT ALEXANDRE INC.\t\t06\t00\t1961 CLUB MONT JOLI.\t\t21\t05\t1947 CLUB DES MONTAGNES ESCARPEES INC.\t\t06\t19\t1961 CLUB DE LA MONTEE.\t\t22\t06\t1965 CLUB MORIN ET MONETTE.\t\t16\t11\t1954 CLUB MOSELLE INC.\t\t21\t04\t1958 CLUB MOUCHAWA.\t\t26\t04\t1963 \t\t28\t10\t1927 \t\t26\t04\t1963 \t.Weedon.\t16\t02\t1960 \t\t.08\t07\t1947 \t.Sto-Foy.\t15\t10\t1957 \t\t21\t04\t1947 \t\t.17\t08\t1961 \tmain\t17\t11\t1959 \t\t.04\t08\t1954 \t\t31\t07\t1959 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 47 6955 Nom de la compagnie Name of the conipany CLUB OU VA.CLUB OUAPISHISH.CLUB DES OURS.CLUB DE L'OURS BLANC INC.CLUB OUSKONDOR INC.CLUB AUX OUTARDES INC.CLUB PACIFIQUE INC.CLUB PAINCHAUD.CLUB PALACHE INC.CLUB PANORAMA.CLUB PAPOU .CLUB PASCHER.CLUB PASSE-PARTOUT INC.CLUB DES PATIENTS INC.CLUB PATRICIA.CLUB PATRICK EST.CLUB DE PECHE GUAY & SAVARD INC.CLUB DE PECHE LO-RI-MI INC.CLUB DES PETITS LACS INC.CLUB PIGALLE.CLUB PIMBINA INC.CLUB DES PINS ROUGES.CLUB PITOU INC.CLUB DES PLAINES INC.CLUB POINTE DU NORD-DA.CLUB DES POLICIERS & POMPIERS DE LA VILLE DE PORT ALFRED CLUB POPULEAU.CLUB DES PORTES DE L'ESTRIE INC.CLUB POUP-POUP.CLUB DES PRETRES INC.CLUB QUATRE SAISONS INC.CLUB DE LA RAME.CLUB DU RAPIDE MANIGANCE.CLUB DES RAPIDES.CLUB RAY-HEC.CLUB LE REFUGE INC.CLUB RICHELIEU INC.Adresse Address Incorporation Date St-Jérôme.06 07 1964 Arvida.14 04 1955 Westmount.11 01 1950 Cabano.12 06 1959 Dolbeau.01 09 1959 Roberval.16 12 1958 Bagotville.07 01 1959 St-Pascal.29 12 1948 Québec.07 09 1961 Jonquière.07 04 1964 St-Adolphe-d'Howard .13 02 1953 La Croche.30 10 1958 Jonquière.01 03 1968 St-Jean-des-Piles.31 08 1967 Cap-de-la-Madeleine .01 09 1953 Dolbeau.29 05 1957 Bergeronnes.06 05 1958 Joliette.11 10 1962 Roberval.01 09 1959 St-Jérôme.16 12 1963 Montréal.17 12 1959 Montréal.28 11 1940 Casey.13 05 1959 Québec.01 05 1956 St-Michel-d'Yamaska.07 04 1964 Port-Alfred.17 10 1969 Warwick.18 12 1950 Acton Vale.15 08 1958 Grand'Mère.05 08 1963 Tadoussac.21 05 1958 Québec.20 10 1962 Chicoutimi.10 06 1964 Trois-Rivières.19 06 1952 Rimouski.10 12 1948 Shawinigan.13 06 1963 St-Pascal.13 11 1969 Canton Baril.06 08 1957 6956 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2k, 1973, Vol.105, No.k7 Nom de la compagnie Name of the company CLUB LE RIKOIS.CLUB ROBB.CLUB ROBIN DES BOIS.CLUB DES ROCHERS.CLUB AUX ROCHERS BLANCS INC.CLUB DE LA ROCHEUSE INC.CLUB ROCHEUX INC.CLUB DES ROLAND.CLUB ROLAND INC.CLUB ROM A LEO.CLUB RO-PEL-VA.CLUB DE RUISSEAU ENCHANTE.CLUB RUISSEAU JAUNE.CLUB DU RUISSEAU ROUGE INC.CLUB RUSTICANA.CLUB TARRAN.CLUB TEKA KOUITA INC.COCOMO CLUB.THE DENNY FISH 4 GAME CLUB INC.ETTEZAG FISH 4 GAME CLUB.FEDERATION DES CLUBS DE CHASSE ET PECHE DU BRAS-HAMEL FISHING AND HUNTING CLUB POUPORE.GATINEAU-PONTIAC FISH & GAME CLUB.GIGUERE FISH 4 GAME CLUB.GRAND'MERE FISH AND GAME CLUB.HAMMER LAKE CLUB.JOSHUA LAKE CLUB.LAKE LAREAU FISH 4 GAME CLUB.LAVAL ROD 4 GUN CLUB.M ANSON VILLE HUNTING 4 FISHING CLUB.MAZURKA INC.McCAN LAKE F.4 G.CLUB INC.MEMPHREMAGOG FISH AND GAME CLUB.MILLE ISLES CLUB.MOPPE LAKE CLUB .MOUNTAIN CREST FISHING 4 HUNTING CLUB INC.NAPETIPI FISH AND GAME CLUB.Adresse Address Incorporation Date Rimouski.17 10 1950 Cap-à-1'Aigle.14 06 1963 Verdun.23 02 1965 Ste-Foy.25 06 1964 Forestville.03 10 1962 Chicoutimi.18 04 1958 St-Léonard.16 09 1958 Québec.16 08 1954 St-Joseph-de-Mékinac.25 09 1961 Shawinigan.27 07 1954 Mont-Laurier.13 05 1950 St-Jérôme.23 07 1964 Ste-Martine.17 03 1964 Forestville.09 06 1961 Mont-Laurier.25 07 1956 St-Léon.18 04 1951 Sillery.23 01 1959 Grande Rivières.01 10 1964 Chapeau.04 09 1962 Windigo.08 09 1955 Dubuc.23 04 1968 Fort Coulonge.30 10 1926 Campbell's Bay.02 06 1964 Rivière-aux-Rats.20 04 1960 Grand'Mère.04 06 1947 Maniwaki.01 10 1964 New Richmond.17 03 1952 La Tuque.01 05 1960 Ste-Rose-de-Laval.19 07 1963 Mansonville.13 11 1962 Jacques-Cartier.06 00 1968 Fort Coulonge.09 04 1962 Pointe-Claire.06 06 1946 Mille Isles.26 08 1964 Laviolette.23 03 1963 Duvernay.29 09 1901 Lauzon.10 03 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° A7_6957 NEW DEREEN CLUB INC.\t\t08\t08\t1960 PARNA FISH & GAME CLUB.\t\t11\t01\t1954 PINE BROOK HUNTING CLUB.\tChandler.\t26\t05\t1959 PINNACLE CLUB.\t\t19\t10\t1964 POINT ROCK FISH AND GAME CLUB INC.\t\t00\t07\t1955 POLICE FISH & GAME CLUB.\tLa Tuque.\t03\t12\t1954 PUMPKIN3EED CLUB .\t\t20\t08\t1963 THE QUEBEC JAY FISH & GAME CLUB.\t\t12\t05\t1964 RAYMER CLUB.\tNew York.\t05\t08\t1963 RCAF ST HUBERT FISH AND GAME CLUB.\tSt-Hubert.\t22\t06\t1964 RIVIERE AUX ROCHES HUNTING & FISHING CLUB.\tSept-Ilcs.\t02\t04\t1965 ROSEMERE COUNTRY CLUB INC.\tRosemère.\t19\t05\t1922 ST.BERNARD FISH AND GAME CLUB.\tSt-Alcxis-dcs-Monts.\t11\t11\t1899 SEA GULL-GERLAND LAKE FISH & GAME CLUB.\tFort Coulonge.\t23\t12\t1963 SHANNOOSH FISH & GAME CLUB INC.\tSte-Anne-des-Plaines.\t.29\t12\t1958 SIDNEY LAKE FISH & GAME CLUB.\t\t28\t04\t1964 SOCIETE DE CHASSE ET DE PECHE DU COEUR DE QUEBEC\t\t15\t05\t1964 \t\t13\t05\t1956 STANLEY ROXTON POND CLUB INC.\tGranby.\t22\t08\t1961 TEN-E-GA CLUB INC.\tCap-de-la-Madeleine.\t.07\t11\t1961 VENNOR LAKE FISH & GAME CLUB.\tShawville.\t24\t02\t1958 WABAK CLUB.\t\t11\t03\t1952 \tShawinigan.\t22\t04\t1954 WEEKECHUM FISH & GAME CLUB INC.\tLennoxville.\t29\t07\t1958 WHITE MOUNTAIN CLUB.\tQuébec.\t12\t08\t1964 WHITE PINE FISHING AND HUNTING CLUB.\tOrillia.\t30\t03\t1955 54695-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54695-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date 6958 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.47 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (1\" partie)\t\tLetters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, cooperatives donne avis, qu'en vertu de la de la Loi des compagnies, il a accordé des constituant en corporation:\tcompagnies et première partie lettres patentes\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name\t\tIncorporation Siège social / Head Office Date ADMINISTRATION M.I.M.INC.M.I.M.MANAGEMENT INC.AGENCES PADO INC AIR SAFARI INC.LES AMBULANCES VAL D'OR INC.ASSURANCES EMOND & CLOUTIER INC.LES ATELIERS D'ANTIROUILLE VAUDREUIL INC.ATELIER ET BOUTIQUE D'ART MON OEIL INC.AUTOMOTEUR F.D.INC.P.D.AUTOMOTIVE INC.ANDRE BACON INC.BEE M CORPORATION LTD.CORPORATION BEEM LTEE BELLEVUE TEXTILE CONVERTERS INC.LES NEGOCIANTS EN TEXTILE8 BELLEVUE INC.BIJOUTERIE AVANT-GARDE INC.AVANT-GARDE JEWELLERY INC.BOBASS LTEE.BOERIO TRANSPORT CO.LTD.LA COMPAGNIE DE TRANSPORT BOERIO LTEE BUFFET TRIO INC.CABAREX INC.CAMPING CARAVANE INC 410St.Nicholas Street.Montreal Montréal.161, rue Gouin, Saint-Charles-Borro- mée.Val d'Or.Hauterive.367, Lalonde, Dorion.1135, rue Laurier ouest, Outremont.8317.boulevard Rivière-des-Prairies, Montréal.6450, Côte des Neiges, suite 322.Montréal.4104 Sherbrooke Street West.Montreal.Montreal.2025 Laurentien Boulevard, Saint-Laurent.Montréal.Montreal.CANUSER IMPORT A EXPORT CO.LTD.COMPAGNIE D'IMPORTATION & D'EXPORTATION CANUSER LTEE CENTRE DE DONNEES IMPERIALE LTEE.IMPERIAL DATA CENTER LTD.LE CENTRE SHELL GUAY INC.GUAY SHELL CENTER INC.CLESEN INC.8001, boulevard Les Galeries d'Anjou.Suite 215.Anjou.1143, rue St-Jean.Québec.Montreal.Montréal.2327 Bourgoin Street, Saint-Laurent.3322.rue Masson, Montréal.Boucherville.28 09 73 11 10 73 09 03 73 23 10 73 26 10 73 25 10 73 05 10 73 16 10 73 23 10 73 22 10 73 17 10 73 24 10 73 10 10 73 08 08 73 03 08 73 24 09 73 16 10 73 14 08 73 10 10 73 26 09 73 31 10 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° 17 6959 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LE CLUB DE SQUASH DE MONTREAL INC.MONTREAL SQUASH CLUB INC.COFFRE-FORT PROTECTION INC.PROTECTION SAFE INC.COMMUNICATION PAUL CLOUTIER INC.CONSEILLERS EN GESTION D'AFFAIRES C.G.A.LTEE.CONSTRUCTION PARCOURT INC.PARCOURT CONSTRUCTION INC.CONSULTANT FINADCO LTEE., FINADCO CONSULTANT LTD.CORPORATION D'AMENAGEMENT PINTO.PINTO DEVELOPMENT CORP.YVES COTE INC.CUISIBEC INC.DANMAUR LIMITEE.DANMAUR LIMITED.DEL DRAPERIES INC.DRAPERIES DEL INC.DEMOLITION B.G.INC.LES DRAPERIES ST-JEAN INC.ECOLE DE CONDUITE VEL INC.ELESKA INC.ENTREPRISES ADONIAS LAURIN INC.LES ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC.LES ENTREPRISES DON OLIVER LTEE.DON OLIVER ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES INTERNATIONALES ROCK LTEE.ROCK INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES PIMIDA INC.LES ENTREPRISES RODEBEC INC.EPICERIE MONKLAND LTEE.MON KL AND GROCERY LTD.EQUIPEMENTS ST-PAUL (SAGUENAY) LTEE.EVALUATIONS GENERALES A.R.A.INC.FERME AVICOLE ST-ANICET LTEE.FERMES ANGUS LIMITEE.ANGUS FARMS LIMITED.LES FORESTIERS HEBERT LTEE.HEBERT FORESTERS LTD.GALERIE INTERNATIONALE DE L'INVENTION INC.INTERNATIONAL INVENTION GALLERY INC.G.GAUTHIER ET FILS LTEE.GESTION JEAN JACQUES INC.JEAN JACQUES HOLDING INC.Montréal.1894.rue Timothée, Montréal.Thetford Mines.Montréal.Lucerne.Longueuil.2166 De Maisonneuve Boulevard West, Montreal.145, 53e Rue ouest, Charlesbourg.924, rue St-Jean, Québec.5005 Jean Talon Street West, Montreal.1055 Notre-Dame Street, Lachine.22 10 73 08 08 73 24 10 73 04 09 73 25 09 73 27 09 73 31 10 73 10 10 73 26 10 73 09 10 73 29 10 73 \t23\t10\t73 \t11\t08\t73 1084, King ouest, Sherbrooke.\t23\t10\t73 1312, rue Sherbrooke est, Montréal 133.\t26\t00\t73 196, rue Principale, Saint-Jacques.\t22\t00\t73 \t28\t00\t73 \t22\t10\t73 2360 Lucerne Road, Suite 2A, Montreal 305.\t24\t10\t73 2520, rue Delorimier, Longueuil.\t17\t10\t73 6, rue des Caps, Saint-Romuald-d'Etchemin.\t16\t10\t73 \t16\t10\t73 \t13\t00\t73 \t22\t10\t73 Montréal.\t06\t00\t73 Bedford.\t31\t10\t73 40, Place de Bretagne, Candiac.\t02\t10\t73 \t30\t10\t73 Saint-Bruno-de-Guigues.\t23\t08\t73 \t21\t10\t73 6960 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.A7 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date 7390, rue Champs Chevrier, Anjou .24 10 73 Saint-Léonard.26 09 73 Saint-Léonard.26 09 73 800 Victoria Square, Suite 612, Mont- 30 07 73 real Montreal.19 09 73 500, Place d'Armes, suite 1833, 01 11 73 Montréal 9.rue Des Erables, Rivière-du-Loup.07 11 73 862 St.Catherine Street East, Mont- 24 10 73 real 1183, Colbert, #9, Sainte-Foy.31 10 73 Deauville.25 09 73 9, rue Dufferin, Granby.29 08 73 7663 Centrale Street, Lasalle.09 10 73 48 Aldred Crescent, Hampstead.19 10 73 6999 Côte des Neiges, Montreal 249.10 10 73 Châteauguay.24 08 73 15085, boulevard Gouin ouest, 11 10 73 Sainte-Geneviève 764, rue Royale, Malartic.14 09 73 7890, rue St-Denis, Montréal.15 10 73 452, rue Churchill, Granby.30 10 73 Matagami.17 09 73 Sainte-Anne-du-Lac.15 10 73 4141 Sherbrooke Street West, Suite 11 10 73 305, Montreal 1355, rue Leclair, Verdun.09 10 73 3430, rue Ste-Catherine est, Montréal 26 09 73 Saint-Nicolas.15 10 73 25, boulevard Auger, Aima.24 10 73 3840, rue Marcil.Montréal.12 10 73 161, rue Principale, Aylmer.28 09 73 Montréal.24 10 73 JEAN GUY GOSSELIN LTEE.JEAN GUY GOSSELIN LTD.LE GRAND SALON DU PRINTEMPS W.H.INC.LA GRANDE FOIRE DE NOEL W.H.INC.H.B.V.REALTY HOLDINGS LIMITED.GESTIONS D'IMMEUBLES H.B.V.LIMITEE HARVARD MORTGAGE d ACCEPTANCE CORP.CORPORATION D'HYPOTHEQUES & DE CREANCES HARVARD LES IMMEUBLES LES ABYMES INC.IMMEUBLES G.L.M.C.INC.LES IMMEUBLES PAPILLON INC.LES INDUSTRIES D.M.D.INC.LES INDUSTRIES DE FOUR PATIO INC.INSTITUT D'ENTRAINEMENT ET DE CONSULTANT DE L'EST INC ISOLATION HABILE INC.ABLE INSULATION INC.JULFARINC.T.T.KATZ INC.LAMPES & PIECES H.M, INC.H.M.LAMPS ci PARTS INC.GERARD LAUZON INC.DENIS LEGAULT INC.MARCHE R.S.INC.MARINIER GOYETTE INC.MATAGAMI ALIGNMENT & SUSPENSION EQUIPMENTS INC.EQUIPEMENTS D'ALIGNEMENT & DE SUSPENSION MATAGAMI INC.MEILLEUR & GRENIER, MARCHAND GENERAL INC.METRO MACHINING CORPORATION.CORPORATION D'USINAGE METRO MEUBLEX INC.LES MOTEURS ET TRANSMISSIONS TRANS-CANADA INC.TRANS-CANADA MOTORS AND TRANSMISSIONS INC.OUELBER INC.LES PETROLES L.F.LTEE.L.P.PETROLEUM LTD.PLACEMENTS CATIEN INC.PLACEMENTS SUROPAR LTEE.LES PRODUITS CREME GLACEE DES ALPES INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° 47 6961 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date PROMOCOM INC.\t4001, boulevard Métropolitain est, Montréal 456.\t16\t10\t73 \t820, rue St-Pierre, Saint-Constant-\t12\t10\t73 PROVICON INC.\t3022.chemin Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac\t10\t09\t73 PUBLICATION PLEIN JOUR INC.\t\t22\t10\t73 \t\t24\t10\t73 I.D.PUBLICITY INC.\t\t\t\t LES PUBLICITES ERABEC INC.\tShawinigan.\tM\t09\t73 LE RENDEZ-VOUS DES ARTISANS DE SCOTSTOWN INC____\tScotstown.\t03\t10\t73 REPARATIONS D'AUTOS DU HAVRE INC.\t2034, rue Du Havre.Montréal.\t31\t10\t73 DU HAVRE AUTO REPAIRS INC.\t\t\t\t RESSOURCES LYNDALE CHIBOUGAMAU LTEE.LYNDALE CHIBOUGAMAU RESOURCES LTD.\t500 Place d'Armes, Suite 1200, Montréal 126\t21\t09\t73 RESTAURANT AUX MOUETTES LIMITEE\tRimouski.\t02\t11\t73 RESTAUROUTE CARTIER INC.\t80, boulevard Cartier, Ricière-du-Loup\t17\t09\t73 \t1059, rue Shearer, Montréal.\t12\t10\t73 YVON RIVEST INC.\t7052, rue Delaroche, Montréal.\t24\t10\t73 ROCHEFORT & SANTOS INC.\t4062A, boulevard Saint-Laurent, Montréal.\t15\t10\t73 SALON DE COIFFEUR STUDIO TROIS INC.STUDIO THREE BARBER SHOP INC.\t9600 Meilleur Street, Montreal.\t30\t10\t73 SANTOS, ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.\t4062A, boulevard St-Laurent, Montréal\t16\t10\t73 SCIERIES DU BAS ST-LAURENT INC\tSaint-Louis-du-Ha! Ha!.\t11\t09\t73 SERVICE AERIEN DU LAC ACHIGAN INC.LAC ACHIGAN AIR SERVICE INC.\t450,305e avenue, Saint-Hippollyte.\t12\t05\t72 LES SERVICES DE RADIO M R M LTEE\t8517 Grouard, Saint-Léonard.\t03\t10\t73 M.R.M.RADIO SERVICES LTD.\t\t\t\t SERVICES SWIT\\TH KS \\îi iVT-fLA llî INC\t\t22\t08\t73 \t\t04\t09\t73 SKI PROS (.CANADA) INC.\t\t18\t09\t73 LES PROS DE SKI (CANADA) INC.\t\t\t\t SOCIETE DES BOISSONS GAZEUSES (SHERBROOKE) INC.\t\t01\t11\t73 LA SOCIETE DE GESTION LCR LTEE\t\t10\t10\t73 SOGIMPER INC .\t\t22\t10\t73 SOLIVES PREFABRIQUEES M.E.B.INC.M.E.B.PREFABRICATED JOISTS INC.\t12035, Bois de Boulognes, Montréal.\t31\t10\t73 LES SPECIALITES DE LOTBINIERE INC\t\t11\t10\t73 SPORTS G.DESMEULES INC.\t\t18\t10\t73 ST-FELICIEN REALTIES LTD.LES IMMEUBLES ST-FELICIEN LTEE.\t18 Gagnon Boulevard, Saint-Félicien.\t25\t10\t73 TAPIS MAGIE DE PERSE LTEE.\t\t22\t1(1\t73 PERSIAN MAGIC CARPET LTD. 6962 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.10.5, No.47 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date TAVERNE MARCEL LALONDE INC.\t.76, boulevard Wilson, Longueuil.\t19\t10\t73 TAXI DU PONT INC.\t.Saint-Georges.\t13\t10\t73 \t.91, rue Hammond, Lachute.\t26\t10\t73 LES INDUSTRIES EAU DE MAREE INC.\t1411 Crescent Street, Room 405A, Montreal 107.\t25\t09\t73 \t12428.rue DeMontigny, Pointe-aux-Trembles.\t29\t08\t73 TRANSPORT P.G.INC.\t\t11\t10\t73 TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.\t\t05\t10\t73 LA VALLEE DE L'HARMONIE D'ALMA INC.\t\t12\t09\t73 VALSCINO INC.\t\t02\t11\t73 VERDON.CAHAY.LABELLE & ASSOCIES INC.\t1500, rue Stanley, suite 336, Montréal.\t01\t11\t73 WORLD RESOURCES CORPORATION .\t\t25\t10\t73 CORPORATION MONDIALE DE RESSOURCES.\t\t\t\t ZEFS MEAT MARKET LTD.\t\t22\tOS\t73 MARCHE DE VIANDE ZEFS LTEE.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 54695-0 Pierre Desjardinb.54695-0 Director of the Companies Service.Lettres patentes (3\" partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date AGENCE TOURISTIQUE OLYMPIADE INC.OLYMPIAD TOURISTIC AGENCY INC.LES AMIS DE LA MAITRISE DU CHAPITRE DE QUEBEC INC.L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE BOIS DE BOULOGNE L'ASSOCIATION RECREATIVE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DU TOURISTE SAINT-CALIXTE NORD (COMTE DE MONTCALM) AUBERGE DE JEUNESSE ST-SAUVEUR INC.CLUB DE L'AGE D'OR DE LA SARRE.CLUB DE L'AGE D'OR DE WINDSOR.CLUB DE M OTONEIGE LES ECLAIREURS INC.Montréal.25 10 73 7, rue St-Stanislas, Québec 4.07 11 73 10500, avenue Bois de Boulogne, 02 10 73 Montréal Lac Duffy, Saint-Calixte Nord.27 09 73 45, chemin du Lac Millet, Saint- 31 08 73 Sauveur-des-Monts.La Sarre.18 10 73 Windsor.02 10 73 Centre des Loisirs Saint-Charles-Bor- 22 10 73 romée, Route rurale numéro 2, Saint-Charles-Borromée GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H novembre 1973, 105' année, n° 17 6963 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date Saint-Zénon.03 10 73 75, boulevard Dorchester ouest, Mont- 26 09 73 tréal 128.Chesterville.02 10 73 Saint-Georges Est.07 11 73 Route rurale numéro 1, Lac Brome.30 07 73 145, boulevard de la Providence, 16 10 73 Lachute 2461, rue St-Jacques ouest, Montréal 24 10 73 Saint-Honoré.28 09 73 417, St-Pierre, suite 30, Montreal____ 26 10 73 Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service, CLUB DE M OTONEIGE ST-ZENON INC.CLUB DE RECREATION DE L'HYDRO-QUEBEC DE LA REGION DE MONTREAL INC.CLUB PAUL-AIR INC.COMITE ORGANISATEUR DES JEUX DU QUEBEC A ST-GEORGES COPAM.FOND DE DOTATION DE L'HOPITAL D'ARGENTEUIL INC.LES LOISIRS FAMILIAUX DE LA PETITE BOURGOGNE INC.PROMOTION DE L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE DU SAGUE-NAY INC.RECHERCHES AMERINDIENNES AU QUEBEC.Le directeur du service des compagnies, 54695-0 Pierre Desjardins.54695-0 Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes AUCLAIR & FRERES INC.J.L.CHARRON LTEE 22 11 61 11 01 73 CITICORP FINANCIAL SERVICES CANADA 03 04 73 LTD.SERVICES FINANCIERS CITICORP CANADA LTEE CLEYN & TINKER, LTD.01 08 62 JEAN-GUY COTE LTEE.04 08 67 DECORATION JEAN MEUNIER INC.26 08 70 LES ENTREPRISES BOBEC INC.25 10 73 28 10 73 Étendant les pouvoirs / Extending the powers 19 10 73 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 15 10 73 Modifiant les dispositions des lettres patente / Amending the provisions of the letters patent 04 10 73 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 12 10 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 16 10 73 Ancien nom / Former name: MEUNIER-RIVEST INC.02 11 73 Ancien nomJ Former name: LES ENTREPRISES GENERALES DE SHIPSHAW INC.MARCEL GAUTHIER CONSTRUCTION INC.07 12 70 22 10 73 Étendant les pouvoirs / Extending the pow- QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.17 Nom / .Van» Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changea IMMEUBLES SYLKA INC.SYLKA REALTIES INC.JOURNAL REGIONAL DES COMTES DE FABRE ET DE LAVAL INC.30 01 58 LIONEL'S FURS (MONTREAL) LTD.10 02 69 LES FOURRURES LIONEL (MONTREAL) LTEE LORENZO INDUSTRIES INC.16 10 61 LES INDUSTRIES LORENZO INC.LUPIEN CONSTRUCTION INC.17 07 69 MACHINERIE LUPIEN INC.,.17 07 69 MANEX INC.11 05 70 J.J.MARTEL INC.07 05 54 NORTHERN EXCAVATION AND PAVING 06 11 69 CO.LTD.NTI NATIONAL INC.08 11 41 OIL HEATING ASSOCIATION OF QUEBEC 28 11 67 INC.ASSOCIATION D'HUILE A CHAUFFAGE DU QUEBEC INC.PRENOR GROUP LTD.12 10 61 GROUPE PRENOR LTEE SECURITE CANA LTEE.16 10 73 CAN A SAFETY LTD.SOCIETE D'OUTILLAGE M.R.LTEE.01 03 71 SOCIMCO INC.01 06 72 (il 10 73 Ancien nom / Former name: OLYMPIA REALTIES CO.LTD.26 05 66 21 09 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les privilèges et restrictions/ Modifying the privileges and restrictions 3) Modifiant les dispositions des lettres pa- tentes / Amending the provisions of the letters patent 08 11 73 Ancien nom / Former name: LIONEL'S FURS (1969) LTD.18 10 73 Étendant les pou voirs / Extending the powers 10 10 73 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 10 10 73 Ancien nom / Former name: LUPIEN CONSTRUCTION INC.27 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital 08 08 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les privilèges et restrictions / Modifying the privileges and restrictions 3) Modifiant les dispositions des lettres pa- tentes/ Amending the provisions of the letters patent NATIONAL APPAREL BUREAU (QUEBEC) 22 01 34 17 09 73 LTD.BUREAU DU VETEMENT NATIONAL (QUEBEC) LTEE NETTOYEUR LE GOLFE INC.27 08 69 25 10 73 Ancien nom / Former name: NATIONAL APPAREL BUREAU (QUEBEC) DIVISION) LIMITED 1) Ancien nom / Former name: F.X.BANVILLE INC.2) Étendant les pouvoirs / Extending the powers 10 09 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent 05 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 12 09 73 Ancien nom / Former name: THE OIL HEATING ASSOCIATION OF MONTREAL INC.03 05 73 Ancien nom ' Former name: ST.LAWRENCE DIVERSIFIED COMPANY LA COMPAGNIE DIVERSIFIEE ST-LAURENT 01 11 73 1) Modifiant le capital /Altering the capital 2) Modifiant les privilèges et restrictions/ Modifying the privileges and restrictions 02 11 73 Ancien nom / Former name.SOCIETE D'OUTILLAGE MIEL (1971) LTEE 09 10 73 Modifiant certaines dispositions dea lettres patentes / Amending certain prolisions of the letters patent GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, «° 47 6965 Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changea VISOSONIE INC.24 06\t72 21 08 73 Ancien nom / Former name: CENTRE DE VISOSONIE AFRICA-NA INC.\t Le directeur du aervice dea compagniea, 54696-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 54695-0 Director of the Companiea Service, Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi dea compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accepté l'abandon de la charte de: Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date ALLAIRE & HAWKINS LTD.\t13\t10\t69\t01\t11\t73 AUBIN & ST-PIERRE (DRUMMOND) INC.\t18\t06\t70\t30\t11\t73 AUBIN & ST-PIERRE (GRANBY) INC.\t20\t05\t60\t30\t11\t73 MURRAY BOWEN HOLDINGS LTD.\t27\t10\t71\t30\t11\t73 CAPRI-COLGER LTD.\t01\t03\t61\t30\t11\t73 CHEZ ALEXANDRA INC.\t30\t07\t65\t30\t11\t73 LE CLUB DU NORD INC.\t20\t10\t61\t30\t11\t73 CONSOL INVESTMENTS CORP.\t27\t12\t71\t30\t11\t71 CORNELL INVESTMENT CORP.\t03\t04\t69\t30\t11\t73 DOMAINE DU PECHEUR INC.\t17\t03\t67\t30\t11\t73 DONTIGNY & CYR INC.\t02\t05\t67\t30\t11\t73 DUFRESNE ET RACINE INC.\t17\t06\t54\t30\t11\t73 DUNLEIGH MEN'S WEAR INC.\t02\t02\t62\t30\t11\t73 ENTREPRISES LAC BOWKER INC.\t21\t12\t71\t30\t11\t73 ESTATE HON.JOHN HEARN INC.\t27\t10\t31\t30\t11\t73 FLEUR DE LYS STAMP VENDING SERVICES INC.LES SERVICES AUTOMATIQUES DE TIMBRES FLEUR DE LYS INC.\t27\t11\t63\t30\t11\t73 GAGNE, LEVESQUE, OUELLET & PELLETIER INC.\t14\t08\t72\t30\t11\t73 \t03\t11\t65\t30\t11\t73 \t29\t10\t63\t23\t11\t73 \t04\t10\t63\t23\t11\t73 \t07\t09\tOU\t30\t11\t73 JACK MARGOLIS HOLDINGS LTD.\t27\t10\t71\t30\t11\t73 LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT McINTYRE LTEE.\t25\t08\t67\t23\t11\t73 6966 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 31, 1973, Vol.10.5, No.L7 Incorporation Dissolution Nom / Xamr Date Date MICHAEL-JOHN ENTERPRISES LTD.\t.25\t10\t60\t23\t11\t73 NORMAN'S AUTO REPAIR LTD.\t04\t11\t60\t30\t11\t73 PLACEMENTS PERCAR LTEE.PERCAR INVESTMENTS LTD.\t.19\t02\t68\t30\t11\t73 \t\t06\t64\t30\t11\t73 \t\t06\t62\t23\t11\t73 RODAIR INC.\t- 22\t12\t59\t30\t11\t73 ROUYN IMPROVEMENTS LIMITED.\t17\t04\t46\t30\t11\t73 LA SOCIETE DE PLACEMENTS DENTURA INC.\t01\t04\t38\t23\t11\t73 TELMAR CONSTRUCTION INC.\t26\t10\t65\t30\t11\t73 WILLIE TREMBLAY INC.\t23\t04\t47\t30\t11\t73 TUBMAN HOLDING CORP.LTD.\t29\t10\t53\t30\t11\t73 VOYAGEUR ABITIBI INC.\t01\t10\t62\t30\t11\t73 JENNIE WEINBERG INVESTMENTS LTD.\t____ 26\t10\t64\t30\t11\t73 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 54695-0 Pierre Desjardins.54695-o Director of the Companies Service.Changement de nom Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a approuvé les règlements de changement de nom suivant: Nouveau nom / New name CAZELAIS ET LA VOIE INC.LA COMPAGNIE DE VETEMENTS J.G.LTEE CONFECTION ST-OURS INC.LA CORPORATION D'INVESTISSEMENTS MONTROW MONTROW INVESTMENT CORPORATION DIROCA INC.ENTREPRISES DE PIPE-LINE UNIVERSEL LTEE.UNIVERSAL PIPE LINE ENTERPRISES LTD.IMPRIMERIE ST-EUSTACHE INC.INVESTISSEMENTS LUCIENNE GAGNON (1973) INC.Change of name The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Ancien nom Incorporation Former name Date CARTIER & CAZELAIS INC.16 01 68 LA COMPAGNIE DE VETE- 08 03 73 MENTS JULIETTE (GRANBY) LTEE CONFECTION ST-ROCH INC.07 02 59 PLACE CHAMBLY LTEE.11 03 64 WILLIAM WRAY INC.11 10 26 SOUDURE UNIVERSELLE DE 30 12 69 PIPELINE LTEE UNIVERSAL PIPE LINE WELDING LTD.C.B.S.ST-LEONARD INC.29 03 71 ANNUAIRE TELEPHONIQUE 26 11 65 JUDICIAIRE (1965) INC.LEGAL TELEPHONE DIRECTORY (1965) INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 47 6967 Nouveau nom / .V« name Ancien nom Former name Incorporation Date MANDELKER ASSOCIATES LTD.LES ASSOCIES MANDELKER LTEE LES MESSAGERIES DYNAMIQUES INC.DYNAMIC CIRCULATION INC.LES PLACEMENTS R.DESJARDINS INC.RORGAL PRODUCTS LIMITED.05 01 73 LES PRODUITS BORGAL LIMITEE LES MESSAGERIES DYNAMI- 03 07 64 QUES INC.LES PLACEMENTS DESJARDINS 26 02 73 INC.54695-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54695-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Fusion de compagnies Amalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Name of new company CLUB DE CHASSE ET PECHE DES LACS MOOSE-CACHE.Siège social Head office Fusion Amalgamation Date Nom des compagnies fusionnées Names of companies amalgamated 3 Westmount Street, Apt.713, Montreal.03 07 73 MOOSE LAKE FISH & GAME CLUB \u2014 CLUB DE CHASSE ET PECHE DU LAC MOOSE CACHE FISH & GAME CLUB \u2014 CLUB DE CHASSE ET PECHE CACHE.54695-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54695-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Avis d'annulation de chartes (2e avis) Notice of annulment of charters (2nd notice) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que les chartes des compagnies ou corporations ci-dessous désignées sont annulées en vertu de la Loi des compagnies: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, the charters of the following companies or corporations are annulled.Nom de la compagnie ou corporation / Name of company or corporation Incorporation Date EQUIPMENTS DU NORD LTEE.31 10 NORTH EQUIPMENTS LTD.A.LABELLE BAR-B-Q.INC.08 01 89 69 54695-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54695-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 6968 Ql TÊBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.17 Commission des transports Québec Transport du Québec Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C 2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu .a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio niotu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.Ill \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).rV' \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, 105' année, n° 17 6969 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) M ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014¦ General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.II \u2014 Avis d'introduction de requête : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of application : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle Q-381 23507-V-D-l LABBE & FILS INC., R.R.5, St-Georges-Ouest, Cté de Beauce.Rôle Q-382 M-140-DYL LES CIMENTS M ASK I LTEE, 46, Grande Carrière, Louiseville, Cté Maskinongé.P.Q.Rôle Q-383 16558-V D-2 GARAGE BELLEMARE & FILS ENRG., 571, rue Ste-Anne, Yamachiche, Cté St-Maurice, P.Q.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant : Transport, restreint - longue distance -route restreinte - De tous points situés dans les districts électoraux provinciaux de Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse et Frontenac à St-Georges-Ouest, Vallée-Jonction et Québec, pour le transp'ort d'animaux vivants pour le public en général.La requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec pour donner le service suivant: Autorisation de louer à long terme à « Garage Bellemare & Fils Enr'g » (Dame Fleurant Pellerin, Bellemarre, opérant sous le nom de:) trois (3) remorques tel que décrites à l'annexe.Modification pour un droit additionnel.Classe: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - conditionnel -Service: De Trois-Rivières et Louiseville à tous les endroits situés dans un rayon de cent milles (100) des limites desdites villes et retour, pour le transport de ciment et les produits connexes, par remorque ordinaire, bétonnière et citerne, pour le compte de Les Ciments Maski Ltée, Louiseville, P.Q.Conditions: 1 ) Pour donner le service précité, le détenteur devra utiliser les remorques, bétonnières et citernes appartenant A et louées au transporteur par l'expéditrice.Les Ciments Maski Ltée, lesdites unités devant être immatriculées a la province de Québec par cette dernière et auprès de la Commission des transports par le transporteur susmentionné qui les remorquera à l'aide de ses tracteurs dûment immatriculé à la Province et auprès de la Commission.2) Le service ci-haut décrit sera valide a la condition que Les Ciments Maski Ltée ait demandé et obtenu de la Commission des Application for permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - From all points located in the provincial electoral districts of Beauçe-North, Beauce-South, Bellechasse and Frontenac to St.Georges-West, Vallée-Jonction and Québec, for the transportation of livestock for the general public.The applicant applies to the Québec Transport Commission in order to provide the following service: Authorization to lease on a long-term basis, to \"Garage Bellemarre & Fils Enr'g\" (Mrs.F'leurant Pellerin, Bellemarre, operating under the name of:) three (3) trailers, as described in the annex.Modification for an additional right.Class: Restricted trucking - long distance - radius - contract - conditional -Service : From Trois-Rivières and Louiseville to all points located within a radius of one.hundred miles (100) from the limits of said cities and return, for the transportation of cement and related products, by standard trailer, concrete-mixer and tank, on behalf of Les Ciments Maski Ltée, Louiseville, P.Q.Conditions: (1) In providing the aforementioned service, the holder shall utilize the trailers, concrete-mixers and tank units belonging to the shipper and leased to the carrier by said shipper, Les Ciments Maski Ltée, the said units must be registered in the Province of Québec by the latter and with the Transport Commission by the aforementioned carrier, which will haul them with its tractors duly registered in the Province and with the Commission.(2) The service hereinabove described shall be valid provided that Les Ciments Maski Ltée have applied for and obtained from the G970 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 1973, Vol.105, No.47 Kôle Q-384 9 CF.(T.A.N.) D-4 LE MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC Hôtel du Gouvernement, Québec, P.Q.Rôle Q-385 1275-DY& 1057-DYV D-l GARAGE FLORENT BEGIN INC., 245.3ème Avenue, Lac Etchemin, Cté Dorchester.Kôle Q-386 2783-A-D-l ALBERT DUMAS, St-Paul.Cté Montmagny, P.Q.(Dist.jud.No 14 Québec-) transports le droit de louer ses remorques, bétonnières et citernes au transporteur, en vue pour ce dernier de donner un service de transport pour son compte.Kemarque: Si la requête est accordée, ce service additionnel nécessitera l'émission et l'utilisation par le détenteur de plaques amovibles a être affixées aux véhicules de l'expéditrice, en donnant le service autorisé pour son compte.Construction d'un passage à niveau.La partie requérante a déposée une requête demandant à la Commission des transports du Québec de rendre une ordonnance autorisant la construction d'un passage :\\ niveau sur le chemin de la deuxième sortie de Port Alfred ft travers la voie du chemin de fer Roberval-Saçuenay (m.17.25 sub.Arvida) d:ins la municipalité de Bagotville.paroisse, comté de Dubuc.Et la partie requérante expose respectueusement que: 1) Pour la sécurité, la protection et la commodité du public, il y a lieu de construire un passage à niveau à l'endroit ci-dessus décrit, tel que montré sur les plans et profils portant le numéro 54-O-D.revisés le 5 Mp-tembre 1973 et préparés par le minii-tère des transports.2) Le coût de construction de ce passage 5 niveau sera entièrement payé par le ministère des transports.3) Les frais d'entretien de ce nouveau passage à niveau seront payés par le ministère des transports.4) Après que les travaux de construction auront été effectués il y aurait lieu de munir ledit passage ft niveau d'un système de protection automatique dont le cofit d'installation, d'opération et d'entretien sera payé par le ministère des transports.Pourquoi la partie requérante prie la Commission de* transports du Québec de rendre une ordonnance décrétant la construction de ce passage a niveau de la manière et suivant les conditions ci-dessus décrites.Nouvelles demandes.La partie requérante demande ft la Commission des transports du Québec, de l'autoriser ft donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location ft court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade aux clients seulement pour remplacer une voiture remisée pour réparation ou accident ou en attendant la livraison d'une voiture neuve ou usagée pour laquelle le client a signé un contrat d'achat chez la détentrice.Service 2 : Location ft long terme (une année et plus) de véhicules de promenade.Service 3: Location ft long terme (uue année et plus de véhicules de commerce et de livraison.Nouvelle demande de permis.Classe permis: Autobus.Service : Transport d'élèves et d'accompagnateurs pour toute activité sportive de St-Paul-de-Montmagny ft tout endroit dans un rayon de 100 mille-'.Transport Commission the right to lease its trailers, concrete-mixers and tank units to the carrier, with a view to said camera providing a transport service on its whan.If°the request is granted, said additional service shall require the issuing, and utilization by the holder, of removable plates to be affixed on the vehicles of the shipper m providing on its behalf the service authorized.Construction of a railroad crossing.The applicant has filed a petition with the Québec Transport Commission requesting it to issue an order authorizing the construction of a railroad grade crossing on the second exit road from Port Alfred across the Rober-val-Saguenay Railway track (m.17.25 sub.Arvida) in the Municipality of Bagotville.Parish.County of Dubuc.And the applicant respectfully states that: (1) For the security, protection and convenience of the public, it is expedient to construct a railroad grade crossing at the place hereinabove described, as shown on the plans and profiles bearing number 54-6-D, revised on September 5.1973 and prepared by the Department of Transport.(2) The cost of construction of this railroad grade crossing shall be borne entirely by the Department of Transport.(3) The cost of maintenance of this new railroad grade crossing shall be borne by the Department of Transport.(4) When such construction is completed, it would be expedient to provide the said railroad crossing with an automatic protection system the cost of installation, operation and maintenance of which shall be borne by the Department of Transport.On these grounds, the applicant requests the Québec Transport Commission to render an order decreeing the construction of said railroad grade crossing in the manner and according to the conditions described above.New applications.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide' the following vehicle-leasing services: Sevrice I : Leasing on a short-term basis (less than a year) of pleasure vehicles only to customers whose automobiles are in the garage for repair or owing to an accident or pending the delivery of a new or used car for which the customer has signed a purchase contract with the holder.Service 2 : Leasing of pleasure vehicles on a long-term basis (one year or over).Service 3: Leasing of commercial and delivery vehicles on a long-term basis (one year or over).New application for a permit.Class of permit: Bus.Service : Transportation of students and their supervisors for any sports event from St.Paul-de-Montmagny to any point located within a radius of 100 miles. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n\" 47 6971 Rôle Q-387 10-V-D-7 GUIl.BAULT TRANSPORT INC., 220.rue Principale, St-Charles-des-Grondines, Cté de Portneuf.Rôle Q-388 1042-DY D-l LES LOCATIONS STE-MARIE INC., 2186 Nord, rue Notre-Dame, Thetford-Mines, Cté Mégantic.Rôle Q-389 1060-DYV D-l EQUIPEMENT AMOS LTEE, 541, Harricana.Amos, Cté d'Abitibi.P.Q.Rôle Q-391 20017-V LA CIE GASPESIA-RIMOUSKI LIMITEE, 386, boul.Jessop, CP.314, Rimouski, Que.Rôle Q-392 3545-A-D-l PATRICE GROLEAU, 65, rue Marquis, Thetford-Mines, Cté Mégantic, P.Q.(Dist.jud.No 27 Québec) Modification de permis, La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service additionnel suivant: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - _ De Montréal aux districts électoraux-provinciaux de Portneuf, Québec.Lévis et Lotbi-nière, pour distribution aux stations-services, agents, distributeurs et clients des produits de Imperial Oil Limited, et retour de barils vides à Montréal ou Québec, le tout pour le compte de ladite compagnie.Modification de permis.La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit: Service: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade à 2186, Notre-Dame Nord, Thetford-Mines, aux clients seulement pendant que leurs véhicules sont en réparation ou sous la garde de la détentrice ou en attendant la livraison d'un véhicule neuf.Demande à la Commission des transports du Québec de modifier la teneur du service pour être autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit : Service : Location à court tei me (moins d'une année) de véhicules de promenade à 2186, Notre-Dame Nord, Thetford-Mines.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser a donner les services de location de véhicules com me suit: Service 1: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison, à 541, rue Harricana, Amos.Service 2 : Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison.Demande de vérification des services de transports fournis : 21508-V Lauréat Canuel, 179, Courtemanche, Ma-tane, Que., intimé.Savoir: En vertu de quelle clause de son permis il donne le service de Montréal à Mont-Joli, pour le compte de Rodrigue & Roussel & Cie Ltée, de Mont-Joli.Nouvelle demande de permis.Classe permis: Autobus.Service: Transport de travaillants (adultes) à partir de la municipalité d'East Broughton à Thetford-Mines (hôpital) par mini-bus y compris la localité de Robertsonville.Modification of permit.The applicant requests that the following additional service be added to its permit : Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - ^ From Montreal to the provincial electoral districts of Portneuf, Québec, Levis and Lotbinière, for distribution of Imperial Oil Limited products to service stations, agents, distributors and customers, and return with empty drums to Montreal or Québec, the whole on behalf of said company.Modification of permit.The applicant is authorized to provide the following vehicle-leasing services: Service : Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than a year) at 2186 Notre-Dame North.Thetford-Mines, to customers only, while their vehicles are under repair on in the custody of the holder or while they are waiting for the delivery of a new vehicle.The applicant requests the Québec Transport Commission to modify the terms of said service in order to be authorized to provide the following vehicle-leasing services: Service: Leasing of pleasure vehicles on short-term basis (less than a year) at 2186 Notre-Dame North, Thetford-Mines.New application.The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following vehicle-leasing services: Service 1: Leasing of commercial and delivery vehicles on a short-term basis (less than a year), at 541 Harricana Street, Amos.Service 2 : Leasing of commercial and delivery vehicles on a long term basis (one year or over).Application for verification of transport services provided by : 21508-V Lauréat Canuel, 179 Courtemanche, Ma-tane.Que., defendant.Namely : Pursuant to which clause of his permit he provides a service from Montreal to Mont-Joli, on behalf of Rodrigue & Roussel & Cie Ltée.of Mont-Joli.New application of permit.Class of permit: Bus.Service: Transportation, by minibus, of workers (adults) from the Municipality of East Broughton to Thetford-Mines (hospital), including the locality of Robertsonville.Rôle Q-393 15332-V-D-l YAMACHICHE TRANSPORT ENRG., (Lucien Bellemare) 811, rue Ste-Anne, Yamachiche, Cté de St-Maurice.Procureurs / Attorneys Me Jean Menard, Chartier, Ménard & Gourdeau.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à-son permis le service additionnel suivant: Transport restreint - longue distance - contrat- A l'aéroport de Dorval, des abattoirs situés dans un rayon de deux cents milles dudit aéroport, pour le transport de viande dans des remorques réfrigérées, pour le compte de la compagnie Cofranca Import-Export Inc.Modification of permit.The applicant requests that the following additional service be added to its permit: Restricted trucking - long distance - contract - To the Dorval Airport, from the abattoirs located within a radius of two hundred miles from said airport, for the transportation of meat in refrigerated trailers, on behalf of Cofranca Import-Export Inc. 6972 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November U, 1973, Vol.105, No.A7 Rôle Q-394 23099-V-D-l LES ENTREPRISES M.T.V.ENRG., (Raoul Millette) 997, rue Champlain.Valcourt, Cté de Shefford, Rôle Q-395 6793-V-D-l BRAZEAU TRANSPORT INC., 380, rue Burke, Rouyn, Cté du Témiscamingue.Rôle Q-396 11437-V-D-l L'ISLET EXPRESS INC.St-Eugène, Cté l'Islet, P.Q.Procureurs/ Attorneys Mes Paquette, Paquette et associés.Q-397 23520-V-D-l PIERRE LEVESQUE, L'Islet, Cté L'Islet, P.Q.Procureurs / Attorneys Paquet Paquet et associés.Q-398 922-A-D-l TF AUTOBUS MONTMAGNY INC., 231, Ave C.l'islois, Montmagny, Cté Montmagny, P.Q.G5V 1A9.Demande de permis de voiturier-remor-queur.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques et f ardiers vides ou remplis pour le compte de : Brazeau Transport Inc., 6793-V, voiturier-roulier, 380, rue Burke, Rouyn, Cté du Témiscamingue.selon les clauses suivantes du permis No 6793-V, à savoir: càz inclusivement ; an à zz inclusivement; aaa à fff inclusivement: (7(7(7, hhh et m (clauses temporaires et expérimentales accordées le 14 février 1973).Modification de permis (voiturier-roulier).La partie requérante demande le permis suivant: Autorisation d'utiliser le service de remorquage de: Les entreprises M.T.V.enrg., 23099-V.voiturier-remorqueur, (Raoul Millette), 997 rue Champlain, Valcourt, Cté de Shefïord.pour le transport de marchandises autorisé par les clauses suivantes de son permis No 6793-V, à savoir: c à z inclusivement: aa à zz inclusivement; aaa &/// inclusivement; fl(7(7, hhh et Hi (clauses temporaires et expérimentales accordées le 14 février 1973).Modification de permis (voiturier-roulier).La partie requérante demande le permis suivant: Autorisation d'utiliser, pour le transport de marchandises autorisé par les clauses c, e, S, l, n, o, q et le droit additionnel re/clauses e, /, g et i du permis No 11437-V, le service de remorquage de: Pierre Levesque, No 23520-V, voiturier-remorqueur, L'Islet, Cté L'Islet.Demande de permis de voiturier-remorqueur.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses c, e, /, l, n, o, et le droit additionnel re/clauses c, /, g et t du permis No 11437-V, pour le compte de: L'Islet Express Inc., No 11437-V, voiturier-roulier, St-Eugène, Cté L'Islet.La requérante demande à la Commission d'annuler tous les voyages tous les soirs de la semaine, le dernier serait celui de 5 heures le soir, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée pour le circuit de la ville de Montmagny.Request for haulaway operator's permit.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul empty or loaded trailers or floats with its duly-registered tractors, on behalf of: Brazeau Transport Inc., 6793-V, carrier.380 Burke Street, Rouyn, County of Témiscamingue.according to the following clauses of permit No.6793-V, namely: r.to z inclusive: aa to zz inclusive; aaa to/// inclusive; (71717, hhh and Hi (temporary clauses on an experimental basis granted on February 14, 1973.) Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit: Authorization to utilize the haulaway transportation service of : Les Entreprises M.T.V.Enrg., 23099-V haulaway operator, (Raoul Millette), 997 Champlain Street, Valcourt, County of Shefford.for the transportation of goods authorized by the following clauses of its permit No.6793-V, namely: c to z inclusive; aa to zz inclusive; aaa to/// inclusive; goo.hhh and Hi (temporary clauses granted on an experimental basis on February 14, 1973.) Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit: Authorization to utilize, for the transportation of goods authorized by clauses c, e,/, /, n, o, q and the additional right re/clauses c,/, g and i of permit No.11437-V, the haulaway transportation service of: Pierre LCvesque, 23520-V, haulaway operator, L'Islet, County of L'Islet.Request for a permit of haulaway operator.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul empty or loaded trailers, with his duly-registered tractors, according to clauses c.c, /, l, n, o, q and the additional right re/clauses e./, g and i of permit No.11437-V, on behalf of: L'Islet Express Inc., 11437-V carrier, St.Eugène, County of L'Islet.The applicant requests the Commission to cancel all trips during the evening, every day of the week, so that the last one would be at 5 o'clock p.m., as well as on Saturdays and Sundays all day, on its route in the Town of Montmagny. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U novembre 1973, 105e année, n* £7 6973 Q-399 251 DYV D.2 LOCATION PINARD INC.PINARD LEASING INC.620, rue Lindsay, Drummondville, Cté Drummond, P.Q.Rôle Q-400 37-A AUTOBUS DESHAIES LTEE DESCHAILLONS Cté Lotbinière, P.Q.et / and 3372-A TRANSPORT SECURITAIRE ST-PROSPER INC.St-Prosper Cté Dorchester, P.Q.Procureurs / Attorneys Paquette, Paquette, Perrault & Rivet.Rôle Q-401 10-V-D-6 GUILBAULT TRANSPORT INC., 220 rue Principale, St-Charles-des-Grondines, Cté de Portneuf.Droit additionnel.La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules suivant: Service : Location de véhicules de commerce (camions) sur une base à long terme (un an et plus).demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services additionnels suivants: Service: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce (camions) à 620, rue Lindsay, Drummondville.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder à Transport Sécuritaire St-Prosper Inc.St-Prosper, Cté Dorchester, P.Q.l'un de ses dervices dûment autorisé en vertu de son permis 37-A soit celui: La propriété du système de transport suivant : Service : De St-Etîenne à Québec et retour.Et ce, afin de favoriser l'émission en faveur du requérant-acheteur d'un permis qui se lira comme suit: De Scott, St-Bernard à Québec et retour avec porte fermée dans St-Gilles sauf pour y laisser monter des passagers en provenance ou à destination de Scott, St-Bernard, St-Narcisse et retour.N.B.: Ce permis autorise le transport de passagers de Pointe St-Gilles à St-Etienne, St-Rédempteur, Ste-Foy, Sillery, Québec.Restriction : Pas de dervice local entre le pont de Québec et Québec ces deux endroits inclus.Parcours à suivre: Scott, St-Bernard, St-Narcïsse, St-Gilles.Pointe St-Gilles, St-Etienne, St-Rédempteur, Québec.Le requérant-vendeur s'engageant à l'avance qu'advenant l'émission d'un permis tel que ci-haut décrit à renoncer et renonce à son permis St-Flavien à Québec et retour.Modification de permis.La partie requérante, dont la clause k de son permis se lit: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - Donnacona à ailleurs dans la province de Québec, à l'ouest des comtés de Québec, Lé-vis et Dorchester, pour le transport de produits manufacturés par Domtar Construction Materials Ltd.et autres marchandises dont cette compagnie a à disposer, et retour avec marchandises endommagées, refusées ou retournées, le tout pour le compte de Domtar Construction Materials Ltd.demande que soient ajoucées les deux (2) compagnies suivantes: Domtar Newsprint Sales Limited; Domtar Newsprint Limited.Additional right.The applicant is authorized to provide the following vehicle-leasing sen-ices: Service : Leasing of commercial vehicles (trucks) on a long-term basis (one year or over).The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following additional services: Service : Leasing of commercial vehicles (trucks) on a short-term basis (less than a year) at 620 Lindsay Street, Drummondville.Transfer of ownership of transport service (sale).The applicant requests the authorization to transfer to Transport Sécuritaire St-Prosper Inc., St.Prosper, County of Dorchester, Québec, one of its services duly authorized under its permit 37-A, to wit: The ownership of the following transport service: Service : From St.Etienne to Québec, and return.The foregoing, in order to facilitate the issuing ot a permit to the applicant-purchaser, which shall read as follows: From Scott, St.Bernard to Québec and return making no stops in St.Gilles, except to board passengers coming from or going to Scott, St.Bernard, St.Narcisse and return.N.B.This permit authorizes the transportation of passengers from Pointe St.Gilles to St.Etienne, St.Rédempteur, Ste.Foy, Sillery, Québec.Restriction: No local service between Québec Bridge and Québec, these two points included.Route : Scott, St.Bernard.St.Narcisse.St.Gilles, pointe St.Gilles, St.Etienne, St.Récemp-teur, Québec.The applicant-vendor binds itself in advance, in the event of the issuing of a permit as described above, to waive its permit for St.Flavien-Québec and return, and hereby waives said permit.Amendment of permit.The applicant, clause k of whose permit reads: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - Donnacona to any point in the Province Québec, located west of the Counties of Québec, Levis and Dorchester, for the transportation of products manufactured by Domtar Construction Materials Ltd., and other goods supplied by this company, and return with damaged, refused or returned goods, the whole on behalf of Domtar Construction Materials Ltd.requests the addition of the names of the following two (2) companies: Domtar Newsprint.Sales Limited; Domtar Newsprint Limited. 6974 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24.1973, Vol.105, No.47 Rôle Q-402 22677-V-D-l ROBERT L.GAUDET, B.P.213.Cap-aux-Meules.Cté des Iles-de-la-Madeleine Procureur ,' Attorney Me Fernand Deveau.Patoine.Deveau et /and Lavoie.Kôle M-655 8491-V D-l PENNSYLVANIA GAZOLINE COMPANY LTD., 1245.rue St-Grégoire, Montréal 176.P.Q.Mise en cause.Rôle M -658 23500-V D-l SOUTH SHORE REPAIRS & SERVICE LTD., 54, rue Morel, Côte Ste-Catherine (Laprairie), Que.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter ft son permis le service additionnel suivant: Transport général-longue distance-route restreinte - De Cap-aux-Meules et de tous les points situés sur les Iles-de-la-Madeleine à Souris, I.P.E., et retour, via le service de traversier opérant entre Cap-aux Meules et Souris, pour le transport de marchandises générales destinées a ou en provenance des points suivants, à savoir: Nouveau-Brunswick : Caraquct, St-Ste-phen, St-John et Moncton; Ile-du-Prince-Edouard: Charlottetown et Souris: Nouvelle-Ecosse: Pictou, Halifax.Sidney et Caribou.Droit additionnel : En donnant le service précité, le requérant demande l'autorisation d'utiliser des véhicules réfrigérés.Cession de la propriété du système de transport (changement de contrôle).Bruno Tétreault, Dame Carmen Nadeau-Tétreault et Lucien Tétreault, requérants-vendeurs.La Société d'Investissement Berem Inc., requérante-acquéreur.Les requérants-vendeurs qui détiennent les actions suivantes dans la compagnie mise en cause: Bruno Tétreault 98 actions ordinaires Dame C.Nadeau-Tétreault 1 action ordinaire M.Lucien Tétreault 1 action ordinaire demandent à la Commission des transports l'autorisation de céder à la requérante-acquéreur toutes les actions sus-mentionnées, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi du transport.A l'avenir les actions de la compagnie mise en cause seront distribuées comme suit: La Société d'Investissement Berem Inc.97 actions ordinaires Benoit Thibault 1 action ordinaire René Boyer 1 action ordinaire Emmanuel Fleury 1 action ordinaire Les actions de La Société d'Investissement Berem Inc.sont réparties comme suit: Benoît Thibault 701 actions René Boyer 701 actions Emmanuel Fleury 401 actions Berman Fleury 100 actions Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, les services de transport suivants: 1) Transport restreint - service local - far-dier - 1 ) Montréal à tous les points situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, et retour.2) Transport restreint - longue distance -rayon - fardier - 2) De Montréal à toutes les localités situées dans la province de Québec, et retour.3)-4) Transport restreint-longue distance-route restreinte - fardier.3) De Montréal aux frontières Québec-Ontario (tous les porta d'entrée) à tous les point situés dans l'Ontario, et retour.Amendment of permit.The applicant wishes to add the following additional service to its permit: General trucking - long distance - restricted route - .From Cap-aux-Meules and from all points located in the Magdalen Islands, to Souris, P.E.I.and return, via the ferry-boat service in operation between Cap-aux-Meules and Souris, for the transportation of general goods bound for or originating from the following points, to wit: New Brunswick: Caraquet, St.Stephen.St.John and Moncton; Prince Edouard Island: Charlottetown and Souris; .Nova Scotia: Pictou.Halifax.Sidney and Caribou.Additional Right: When providing the aforesaid service, the applicant requests the authorization to utilize refrigerated vehicles.Transfer of ownership of transport service (change of control).Bruno Tétreault.Mrs.Carmen Nadeau-Tétreault and Lucien Tétreault.applicant-vendors.La Société d'Investissement Berem Inc., applicant-purchaser.The applicant-vendors who hold the following shares in the company mist en cause: Bruno Tétreault 98 common shares Mrs.C.Nadeau-Tétreault 1 common share Lucien Tétreault 1 common share request from the Transport Commission the authorization to transfer all the above-mentioned shares to the applicant-purchaser, in compliance with the provisions of section 39 of the Transport Act.The shares of the company mise en cause shall henceforth be distributed as follows: La Société d'Investissement Berem Inc 97 common shares Benoit Thibault 1 common share René Boyer 1 common share Emmanuel Fleury 1 common share The shares of La Société d'Investissement Berem Inc.are distributed as follows: Benoit Thibault 701 shares René Boyer 701 shares Emmanuel Fleury 401 shares Berman Fleury 100 shares New request: The applicant requests that the Commission authorize it to provide the following transportation services under the prescribed terms and conditions: (1) Restricted trucking - local service -float - (1) Montreal to all points located within a distance of 5 miles from the limits of said City, and return.(2) Restricted trucking - long distance -radius - float - (2) From Montreal to all localities located in the Province of Québec, and return.(3)-(4) Restricted trucking - long distance - restricted route - float.(3) From Montreal to the Québec-Ontario border (all ports of entry) to all points located in Ontario, and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.9.1 novembre 1973.105' année, n\" 17 6975 Rôle M-657 13473-V D-l FELIX QUINTAL, 24A, rue St-Louis, Ville Lemoyne.Chambly, Que.Rôle M-658 3540-A D-l LOUIS-CHARLES HEBERT, (pour une Compagnie limitée à être formée), 345, boul.Victor Hugo, Brossard, P.Que.Rôle M-660 1059-DYV D-l LOCATION DE CAMIONS A & W ENRC.A & W TRUCK LEASE REC'D., (Alain Bertrand opérant sous le nom de:) R.R.32, Danville, Cté Richmond.P.Q.Rôle M-«61 1093-DY D-l BOULEVARD DODGE CHRYSLER (1963) LTEE 330, ouest, boul.Crémazie, Montréal, P.Q.H2P 1C7.4) De Montréal aux frontières Québec-Nouveau-Brunswick (tous les ports d'entrée) à tous les points situés dans le Nouveau-Brunswick, et retour.Dans les quatre cas, pour le transport de machinerie lourde par fardier pole trailers.Goose neck, remorque à trombone pour le public en général.Droit additionnel: En donnant les services précités, la détentrice aura le droit d'utiliser des camions ordinaires et des remorques ordinaires, pour le transport de pièces, équipement, effets d'entrepreneur lesquels sont accessoires aux objets transportés par fardier pole trailers, Goose neck et remorque à trombone.Condition: Les clauses 3 et 4 ci-dessus ne seront exploitées que conjointement avec les permis connexes à être obtenus des autorités concernées et à être déposés à la Commission des transports du Québec.Cession de la propriété du système de transport (vente).Félix Quintal demande l'autorisation de céder à: Rutan Inc., 3645 est, boul.St-Joseph, Montréal 405, Que.la propriété du système de transport suivant: Permis No 13473-V.a) Transport général - service local - a) Ville LeMoyne et tous les endroits situés à une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville (à l'exclusion de Mtl).b) Transport général - longue distance -route restreinte ¦- 6) De Ville LeMoyne à Mtl et retour, pour le transport de marchandises destinées à Ville LeMoyne ou en provenant.Ce permis devra se lire conformément à l'Ordonnance générale.Le requérant a fait une demande de permis pour exploiter un service de visites touristiques en autobus dans la ville de Montréal à partir de la Rive-Sud et de Montréal.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser a donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1: Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs et remorques) a long terme (un an et plus).Service 2: Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs et remorques) à court terme à R.R.32, Danville, P.Q.Droit additionnel: La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location à long terme (une année et plus) de véhicules de promenade, demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser a donner les services additionnels suivants: (4) From Montreal to the Québec-New Brunswick border (all ports of entry) to all points located in New Brunswick, and return.In all four cases, for the transportation of heavy machinery by float (pole-trailer type), goose neck, telescopic trailer, for the general public.Additional right: In providing the aforementioned services, the permit-holder shall have the right to use standard trucks and standard trailers, for the transportation of parts, equipment, contractors' effects which are accessory to the objects transported by pole-trailer float, goose neck and telescopic trailer.Condition: The aforesaid clauses 3 and 4 shall only be operated jointly with the related permit to be obtained from the authorities concerned and to be filed with the Québec Transport Commission.Transfer of ownership of transport service (sale).Félix Quintal requests authorization to transfer to: Rutan Inc., 3645 est, boul.St-Joseph, Montréal 405, Que.the ownership of the following transport service: Permit No 13473-V.(a) General trucking - local service - (a) Town of LeMoyne and all points located with a distance of 5 miles from the limits of said City (to the exclusion of Montreal).(6) General trucking - long distance -restricted route - (5) From the Town of LeMoyne to Mtl and return, for the transportation of goods shipped to or originating from the Town of LeMoyne.The drafting of this permit must be in compliance with the General Order on Trucking.Application is made for permit to operate sightseeing bus tours in the City of Montreal from South-Shore and from Montreal.New request: The applicant requests that the Québec Transport Commission authorize it to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1 : Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) on a long-term basis (one year or over).Service 2: Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) on a short-term basis at R.R.32, Danville, P.Q.Additional right: The applicant, which is authorized to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1: Long-term leasing (one year or over) of pleasure vehicles.requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following additional services: 6976 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.1,7 Rôle M-662 109-DYV D-l RYDER TRUCK RENTAL LIMITED, 1440, Montée de Liesse, Montréal 384, P.Q.Rôle M -663 785-DYV D-l MARLEASE INC., 61 sud, rue St-Jacques, Coaticook (Stanstead), P.Q.Rôle M-«64 1052-DYV D-l ROULOTTES DEL-CAN TRAILERS, (John.R.Delves opérant sous le nom de), 378.rue St.Eustache.St.Eustache, Cté de Deux-Montagnes, Rôle M-«65 1270-DY & 1053-DYV D-l ACME RENT A CAR REG'D., (Laurent Piquette, opérant sous le nom de:), 2024, rue Holmes, St-Hubert, P.Q.Service 2: Location A court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade aux clients seulement pendant que leurs véhicules sont en réparation ou en attendant la livraison d'un véhicule neuf A 330 ouest boul.Crémazie, Montréal.Changement d'adresse.La partie requérante qui e.«t autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit : Location à court terme de véhicules de commerce e' de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la route A: 49, rue St-Etienne.Hull: 1200, avenue Hiekson, Verdun; 1400 Montée de Liesse, Montréal 381; 250, 2e Rue, Liinoilou, Quéliec: 8610.rue Lafrenaie.St-Léonard; 1437.boul.Industriel.Ste-Fov; 285.rue St-Paul.Chicoutimi:\" 8650, rue .larry, Ville d'Anjou, demande i\\ la Commission des transports du Québec de changer l'adresse du bureau de location de Québec pour qu'A l'avenir le permis se lise comme suit : Location a court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la route à : 49, rue St-Etienne, Hull; 1200, avenue Hiekson, Verdun; 1400, Montée de Liesse, Montréal 3SI; 250, 2e Rue, Liinoilou, Québec; 8010, rue Lafrenaie, St-Léonard; 1437, boul.Industriel; 2650.rue Dalton, Parc Colbert.Ste-Foy, Québec: 285, rue St-Paul.Chicoutimi; 8650, rue Jarry, Ville d'Anjou.Demande additionnelle.La requérante qui détient de la Commission des transports du Québec un permis pour les services suivants: Service 1: Location de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) à court terme, au sens du code de la Route, à 61 sud.rue St-Jacques, Coaticook (Stanstead.P.Q.).Service 2: Location de véhicules de commerce et de livraison (cnmions, tracteurs, remorques), A long terme (un an et plus).Domande d'être autorisée a opérer une succursale nu: 1147, rue Pitfield Dorval, P.Q.pour opérer les services de location ci-haut décrits.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser A donner les services de locations de véhicules comme suit: Service: Location A court terme (moins d'une année) de roulottes et tcnles-roulottes, A 378 rue St-Eustache.St-Eustache, P.Q.Nouvelles demandes.La partie requérante demande A la Commission des transports du Québec de l'autoriser A donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location A court terme de véhicules de promenade A 2024.rue Holmes.St-Hubert.Service 2: .Short-term leasing (less than a year) Çl pleasure vehicles to its customers only while their vehicles are under repair or while they expect the delivery of a new vehicle, at 330 Crémazie Blvd.West, Montreal.Change of address.The applicant, which is authorized to provide vehicle-leasing services as follows: Short-term leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) as defined by the Highway Code at: 49 St.Etienne Street, Hull; 1200 Hickson Avenue, Verdun; 1400 Montée de Liesse.Montreal 384; 250 - 2nd Street, Limoilou.Québec; 8610 Lafrenaie Street.St.Léonard: 1437 Industriel Blvd.Ste.Foy: 286St.Paul Street, Chicoutimi; 8650 Jarry Street, Town of Anjou; requests from the Québec Transport Commission authorization to change the address of the Québec rental office so that the permit may henceforth read as follows: Short-term leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) as defined bv the Highway Code at: 49 St.Etienne Street.Hull: 1200 Hickson Avenue.Verdun; 1400 Montée de Liesse.Montreal 384 ; 250 - 2nd Street Limoilou.Québec; 8610 Lafrenaie Street, St.Léonard; 1437 Industriel Blvd.; 2650 Dalton Street.Pare Colbert, Ste.Foy, Québec; 285 St.Paul Street.Chicoutimi ; 8650 Jarry Street.Town of Anjou.Additional request.The applicant, which holds a permit for the following services delivered by the Québec Transport Commission : Service 1 : Short-term leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) as defined by the Highway Code, at 61 St.Jacques Street South.Coaticook (Stanstead, P.Q).Service 2: Long-term leasing (one year or over) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers).Requests to lie authorized to operate a branch at: 1147 Pitfield Street, Dorval, P.Q., to provide the leasing services hereinabove described.New request.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide vehicle-leasing services as follows: Service : Short-term leasing (less than a year) of travel trailers and tent trailers at 378 St.Eustache Street.St.Eustache, P.Q.New request.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1 : Short-term leasing of pleasure vehicles at 2024 Holmes Street, St.Hubert. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, M novembre 1973, 105' année, n° 6977 Rôle M-66G 1271-DY D-I LOCATION D'AUTOS ST.GERMAIN LTEE, ST.GERMAIN AUTO LEASING LTD., 260.boul.Harwood, Dorion, Cté Vaudreui], P.Q.Role M-667 1087-V-D-3 COUPAL TRUCKING LTD., 1765, rue Mullins.Montréal 104, P.Q.Rôle-668 14519 M-V COWANSVILLE EXPRESS INC., 264 rue Hanson, Cowansville, Cté de Missisquoi Rôle M-669 20978-V-D-l FREEPORT TRANSPORT INC., 1200 Butler Road, Freeport, Penn.16229.U.S.B.P.124 Ste-Anne-de-Bellevue, Que.Service 2: Location à long terme de véhicules de promenade.Service 3: Location a court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, légers % tonne ou moins) A 2024, rue Holmes, St-Hubert.Service 4 : Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions légers % tonne ou moins).Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1: Location de véhicules de promenade (automobiles) à long terme (un an et plus).Service 2: Location à court terme de véhicules de promenade (automobiles) à 260, boul.Harwood, Dorion.à ses clients et aux clients de St.Germain Chevrolet-Oldsmobile Ltée., qui ont des véhicules en réparation ou qui attendent la livraison d'un véhicule neuf.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service additionnel suivant: Transport restreint-longue distance-route restreinte - De Montréal à Ste-Scholastiquc, pour le transport de marchandises, pour le compte de Larivière Inc.Modification de permis.La requérante désire ajouter à son permis e service suivant: Transport restreint-longue distance-rayon-irrégulier- De la ville du Lac Brome à tous les endroits de la province de Québec situés dans un rayon de 200 milles des limites de la ville du Lac Brome, à l'exclusion de Montréal, Sherbrooke et Québec, et retour, pour le transport de marchandises, pour le compte d'un (1) seul expéditeur par voyage.En remplacement de la RT-54 du 19 juin 1973 publiée dans la Gazette of/icielfc riu Quebec No 32 du 11 août 1973 :\\ la page 4718.Modification de permis (droit additionnel).La requérante demande à la Commission d'ajouter les services suivants à son permis: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contract - De Tracy, (Que.) à la frontière Québec-Ontario (port d'entrée: Rivière-Beaudette) en transit à travers la province d'Ontario, jusqu'à la frontière internationale entre l'Ontario et les Etats-Unis, par tous les postes frontières à tous les endroits aux Etats-Unis.Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat \u2014.De Tracy, (Que.) à la frontière Québec-Etats-Unis (tous ports de sortie) à des endroits aux Etats-Unis.Dans les deux cas, pour le transport de fer en poudre pour le compte de Québec Metal Powders Limited.Restriction : Ce permis doit être exploité avec le permis No MC-113666 et sub.82 délivré par l'I.C.C.Service 2: Long-term leasing of pleasure vehicles.Service 3: Short-term leasing of commercial and delivery vehicles (lightweight trucks, % ton or less) at 2024 Holmes Street, St.Hubert.Service 4 : Long-term leasing (one year or over) of commercial and delivery vehicles (lights weight trucks, % ton or less.) New request.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following vehicle leasing services : Service 1 : Long-term leasing (one year and over) of pleasure vehicles (automobiles).Service 2: Short-term leasing of pleasure vehicles (automobiles) at 260 Harwood Blvd.Dorion, to its customers and the customers of St.Germain Chevrolet-Oldsmobile Ltée, whose vehicles are under repair or who expect the delivery of a new vehicle.Modification of permit.The applicant requests authorization to add the following additional service to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - From Montreal to Ste.Scholastique, for the transportation of goods on behalf of Larivière Inc.Modification of permit.The applicant wishes to add to its permit, the following service: Restricted trucking-long distance-radius-irregular - From Ville du Lac Brome to all points of the Province of Québec situated in a radius of 200 miles of the limits of Ville du Lac Brome, excluding Montreal, Sherbrooke and Québec, and return, for the transportation of merchandises, for the account of only one (1) shipper per trip.To replace RT-54 dated June 19, 1973, published in the Quebec Official Gazette No.32 dated August 11, 1973, on page 4718.Modification of permit (Additional right).The applicant asks the Commission to add to its permit the following services: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Tracy, Que., to the Québec-Ontario border (Port of entry: Rivière-Beaudette) in transit through the Province of Ontario, to the international boundary line between Ontario and the United States, all points of crossing to points in the United States.Restricted trucking - long distance - restricted route - contract -.From Tracy, Que.to the Québec-U.S.border (all ports of exit), to points in the United States.In both cases, for the transportation of powdered iron for the account of Québec Metal Powders Limited.Restriction : This permit is to be operated in conjunction with I.C.C.Permit No.: MC-113666 and sub.82. 697S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 Rôle M-670 22429-V D-l JEAN VANIER TRANSPORT 7900, boul.Métropolitain Ville d'Anjou, Montréal 4 Que.434, Rôle M-671 23477-V-D-l NORTH SHORE TRANSPORT REC'D {Keith Cox opérant sous le nom de) 25 Stone Crest, Dollard-des-Ormeaux, Que.Rôle M-672 12-A (D.-4) BRANDON TRANSPORT INC.143, rue Dequoy.St-Gabriel, Cté Berthier, P.Que.Rôle M-673 6082-V-D-l ALFRED B.PAG EAU Cookshire.(Compton), Que.Cession de la propriété du système de transport (vente).Jean Vanier demande l'autorisation de céder à: M.R.Transport Enrg., (Michel et René Vanier opérant sous le nom de), 7900, boul.Métropolitain, Ville d'Anjou, Montréal 434, Que.la propriété du système de transport suivant: Permis No 22429-V.a) Transport général \u2014 service local - a) Montréal et les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville.b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - b) Des magasins Woolco Department Store situés dans le Montréal-Métropolitain aux autres magasins de la même compagnie situés à Trois-Rivières, Granby, Sorel, Jo-liette.Valleyfield, Sherbrooke et Drummondville, pour le transport de marchandises, pour le compte de Woolco Department Store.Nouvelle demande de permis.La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant : Transport général - service local -Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville.La requérante qui opère divers services demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'étudiants fréquentant la polyvalente Thérèse-Martin de Joliette.à l'occasion de voyages à charte-partie pour voyages sportifs ou culturels de Joliette à Montréal, et retour, par les deux (2) parcours suivant: Parcours No.1 : Dé Montréal à St-Thomas, Berthier, St-Norbert et St-Gabriel.Parcours No 2: De Montréal à L'Assomption, Joliette, St-Félix-de-Valois, St-Cléophas et St-Gabriel.Cession de la propriété du système de transport (vente).Alfred B.Pageau demande l'autorisation de céder il : André Beauregard.Cookshire, (Compton), Que.1126-V la propriété du système de transport suivant: Permis No 6082-V.a) Transport général - service local - a) Cookshire et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité.5) Transport général - longue distance -rayon - 5) De Cookshire à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite municipalité en suivant les routes principales et retour.c) Transport général - longue distance -route restreinte - c) De Cookshire.Bury et Scotstown à Sherbrooke et retour.Transfer of ownership of transport service (sale).Jean Vanier requests authorization to transfer to: M.R.Transport Enrg., (Michel and René Vanier operating under the name of), 7900 Metropolitan Blvd., Town of Anjou, Montreal 434, P.Q.the property of the following transport service : Permit No.22429-V.(a) General trucking - local service - (a) Montreal and all points located over a distance of not more than five (5) miles from the limits of said City.(6) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (6) From the stores of Woolco Department Store located in Greater Montreal to the other stores of said company located in Trois-Rivières, Granby, Sorel, Joliette, Valleyfield, Sherbrooke and Drummondville, for the transportation of goods, on behalf of Woolco Department Store.New permit application.The applicant requests authorization from the Commission to provide the following transportation service, according to the pre-scril>cd conditions: General trucking - local service - Montreal and all points located over a distance of not more than five miles from the limits of said City.The applicant who operates various services, requests authorization to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service: Transportation of students attending the Polyvalente Thérèse-Martin in Joliette.on charter trips for sports or cultural trips from Joliette to Montreal and return, by the following two (2) routes: Route No.1: From Montreal to St.Thomas.Berthier, St.Norbert and St.Gabriel.Route No.2: From Montreal to L'Assomption, Joliette, St.Félix-de-Valois, St.Cléophas and St.Gabriel.Transfer of ownership of transport service (sale).Alfred B.Pageau requests authorization to transfer to: André Beauregard, Cookshire, (Compton).P.Q.1126-V the ownership of the following transport service: Permit No.6082-V (a) General trucking-local service- (a) Cookshire and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said Municipality.(6) General trucking - \"long distance - radius - (6) From Cookshire to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said Municipality, along the main highways, and return.(el General trucking - long distance-restricted route - M From Cookshire, Bury and Scotstown to Sherbrooke and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H novembre 1973, 105e année, «° 47 6979 Rôle M-674 23452-V-D-l IVAN DENNING & SONS ENTERPRISES LTD.R.R.3, Strathroy, Ontario Rôle M-675 23448-V-D-l JACQUES MARTIN.R.R.No 2, Saint-Hyacinthe, Que.Remarque: Re: André Beauregard, Dossier 1I26-V.Il s'agit du transfert de la clause « C » seulement, puisque l'acquéreur donne déjà les services selon les clauses A et B de son permis.Nouvelle demande.La requérante s'est adressée à la Commission afin d'obtenir le permis suivant: Transport de comptoirs, chariots et étagères préfabriqués et d'accessoires s'y rattachant, vitrines, coupe-papier, séparations (cloisons) et bottes d'étalage, et lors du voyage de retour, transport des matériels nécessaires à la fabrication desdites marchandises, le tout exclusivement pour le compte de E.J.Wright Central Limited et Wright Assemblies Limited, toutes deux situées à Strathroy (Ontario), selon les clauses suivantes : a) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat.a) De la frontière Québec-Ontario (via tous ports d'entrée) à tous les endroits situés au Québec et retour.(Origine ou destination: les établissements desdits expéditeurs à Strathroy (Ontario).6) Transport restreint - longue distance -route restreinte - en transit - contrat - b) En transit, de la frontière Québec-Ontario à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (via tous ports d'entrée) et retour.(Origine ou destination: les établissements desdits expéditeurs à Strathroy (Ont.) et les endroits dans les provinces maritimes suivant autorisation).c) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - c) De la frontière Québec-Nouveau- Brunswick (tous ports d'entrée) à tous les endroits situés au Québec et retour.(Origine ou destination: les endroits dans les provinces maritimes, suivant autorisation).Restrictions: 1) Les clauses a, b et c ci-dessus mentionnées doivent être exploitées avec le certificat complémentaire émis le 16 août 1973 par l'Ontario Highway Transport Hoard et avec les autorisations complémentaires devant être émises par les autorités y mentionnées, selon l'exigence du cas, dont copie doit être déposée auprès de la Commission.2) Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises ci-dessus mentionnées doivent être dûment immatriculés dans la province et à la Commission.3) En donnant le service en vertu du présent permis, le détenteur n'est pas autorisé à donner un service local dans la province de Québec.La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De St-Hyacinthe à Montréal, pour le transport de vêtements manufacturés livrés sur supports, pour le compte de: Pantalon Elysée.Note: Re: André Beauregard, File 1126-V.This application concerns the transfer of clause \"C\" only, since the purchaseris already providing the services authorized by clause A and B of his permit.New application: The applicant has petitioned the Commission, in order to obtain the following permit: Transportation of pre-built counters, carts, shelves and incidental parts therefor, show cases, paper cutters, partitions and store displays and, on the return movements, goods used in the manufacture of same, exclusively for the account of E.J.Wright Central Limited and Wright Assemblies Limited, both of Strathroy, Ontario, as follows: a) Restricted trucking - long distance -radius - contract - («z) From the Québec-Ontario border (via all ports of entry) to all localities situated in the Province of Québec and return.(Origin or destination: the installations of the said shippers at Strathroy, (Ontario).(b) Restricted trucking - long distance -restricted route - in transit - contract - (6) In transit, from the Québec-Ontario border to the Québec-New Brunswick border (via all ports of entry) and return.(Origin or destination: the installations of the said shippers at Strathroy, Ont.and points in the Maritime Provinces, as authorized).(c) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (c) From the Québec-New Brunswick border (all ports of entry) to all localities situated in the Province of Québec and return.(Origin or destination: points in the Maritime Provinces, as authorized).Restrictions: (1) Clauses a, b and c above mentioned are to be operated in conjunction with a complementary certificate issued by the Ontario Highway Transport Board on August 16, 1973 and also in conjunction with complementary authorities to be issued by the other jurisdictions referred to therein as may be required, copy of which must be filed with the Commission.(2) Vehicles utilized to effect the transportation of the above mentioned goods are to be registered fully with she Province and with the Commission.(3) No local service is authorized within the Province of Québec, when giving a service in virtue of this permit.The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following service, according to the prescribed conditions: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From St.Hyacinthe to Montreal, for the transportation of manufactured clothing delivered on hangers, on behalf of: Pantalon Elysés. 69S0 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2I\u201e 7975, Vol.105, No.17 Hole M-«76 23382-V-D-l EXCAVATION M.LAÇASSE LTEE.R.R.I.Lac Carré (Terrebonne), Que.R61e M-677 104-V-D-l BOYD'S EXPRESS LIMITED 255 Bethany Road, Lachute, Cté Argenteuil.P.Q.Rôle M-678 23221-V CEORCE A.LEWIS LTD., 7, Buckwood Court.St.Stephen.New-Brunswick.Nouvelle demandé: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, les services de transport suivants: Transport restreint - service local - fardier - St-Jovite et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite municipalité, pour le transport de machineries lourdes, pour le public en général, par fardier.Transport restreint - longue distance -route restreinte - fardier - De Lac Carré & Ste-Agathe, St-Faustin, La Conception, St-Jovite, La belle, pour le transport de machineries lourdes, pour le public en général, par fardier.Modification du droit additionnel No 3: La requérante désire ajouter au droit additionnel No 3, qui se lit comme suit: « Pour le transport d'explosifs, pour le compte de Canadian Industries Limited de Brownsburg à tous les endroits qu'elle est autorisée à desservir en vertu du permis de camionnage précité »: Le nom de : Canadian Safety Fuse Co.Ltd.qui est une filiale de Canadian Industries Ltd.Demande de droits additionnels.La requérante s'est adressée à la Commission afin d'obtenir le droit de donner les services suivants: 1) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - véhicules isothermes - 1) De St-Jean-Baptiste-de-Rouville.Ste-Rosalie et Berthier, (Que.) à la frontière Québec-Etats-Unis (Port de sortie: Blackpool), pour le transport de viandes et de produits de boucherie frais et congelés, par camions isothermes, pour le compte de Québec Poultry Co.Ltd.(destination: endroits il Terre-Neuve, via les Etats-Unis, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse).2) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - véhicules isothermes.2) De la ville de Québec-Nouveau-Bruns-wick (tous ports d'entrée) pour le transport de viandes et de produits de boucherie frais et congelés, par camions isothermes, pour le compte de Québec Poultry Co.Ltd.(Destination: endroits à Terre-Neuve, via les provinces du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Ecosse).3) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - véhicules isothermes.3) Du Montréal métropolitain à La frontière Québec-Etats-Unis (port de sortie: Blackpool! pour le transport de viandes et de produits de boucherie frais et congelée, par camions isothermes, pour le compte de Canada Packers Ltd.Provisioners Maritimes Limited et Swift Canadian Co.Ltd.(Destination: endroits à Terre-Neuve, via les Etats-Unis et les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse).New application: The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following service, according to the prescribed conditions: Restricted trucking - local service - float - St.Jovite and all points located over a distance of not more than five miles from the limits of said Municipality, for the transportation of heavy machinery, by float, for the public at large.Restricted trucking - long distance - restricted route - float - From Lake Carré to Ste.Agathe, St.Faustin, La Conception, St.Jovite.Labelle, for the transportation of heavy machinery, by float, for the public at large.Modification to additional right No.3: The applicant wishes to add to additional right No.3 which reads as follows: \"To transport explosives, for the account of Canadian Industries Limited of Brownsburg to all localities which is authorized to serve in virtue of the above-mentioned trucking permit \".The name of: Canadian Safety Fuse Co.Ltd.which is a subsidiary of Canadian Industries Ltd.Application for additional rights.The applicant has petitioned the Commission in order to obtain the right to give the following services: (1) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - temperature controlled vehicles - (1) From St-Jean-Baptiste-de-Rouville.Ste-Rosalie and Berthier, Que., to the Quebec-United States border (Port of exit : Blackpool) for the transportation, in temperature controlled vehicles, of meat and meat products, fresh and frozen, for the account of Québec Poultry Co.Ltd.(destination: Points in New Foundland, via the United States, New Brunswick and Nova Scotia).(2) Restricted trucking long distance -restricted route - contract - temperature controlled vehicles - (2) From Québec City to the Québec-New-Brunswick border (all ports of exit) for the transportation, in temperature controlled vehicles, of meat and meat products, fresh and frozen, for the account of Québec Poultry Co.Ltd.(Destination: Points in New Foundland, via the Provinces of New Brunswick and Nova Scotia).(3) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - temporature controlled vehicles - (3) From Metropolitan-Montreal to the Quebec-United States border (port of exit: Blackpool) for the transportation, in temperature controlled vehicles, of fresh and frozen meat and meet products for the account of Canada Packers Ltd., Provisioners Maritimes Limited and Swift Canadian Co.Ltd.(Destination: points in New Foundland, via the United States and the Provinces of New Brunswick and Nova Scotia). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SL novembre 1973, 105' année, n\" 17 6981 Rôle M-679 23508-V-D-l DANIEL HOULE ENRC, (Daniel Houle opérant sous le nom de) 10, rue Paiement, Labelle, (Labelle), Que.Rôle M-680 14440-V-D-l THEODORE MORIN TRANSPORTS ENRG.(Théodore Morin), 195, rue Principale, St-Alexis (Joliette-Montcalm), Que.Restriction: Les services précités doivent être exploités avec les certificats ou permis No T-PC-X 127 émis le 16 juin 1972 par le New Brunswick Motor Carrier Board et avec les certificats ou permis devant être émis par les autorités y mentionnées, selon l'exigence du cas, dont copie doit être déposée auprès de la Commission des transports du Québec.Nouvelle demande.La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat \u2014 De Labelle et La Minerve à Beauharnois, Montréal, Thurso, Gatineau, Portage-du-Fort et Joliette, pour le transport de copeaux de bois et bran de scie, pour le compte de: Bois Laurentien Inc.; Les Produits Forestiers; Emeric Bergeron & Fils Ltée.Modification: La partie requérante désire ajouter à son permis la clause suivante: Transport général-longue distance-rayon-St-Alexis et tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite localité, et retour, pour le transport de marchandises.Restriction : The above-mentioned services are to be operated in conjunction with certificates or permits No.T-PC-X 127 issued by the New-Brunswick Motor Carrier Board on June 16.1972 and with certificates or permits to be issued by the other jurisdictions referred to therein, as may be required, and copy of which must be filed with the Québec Transport Commission.New application.The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following transport service, according to the prescribed conditions: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Labelle and La Minerve to Beauharnois, Montreal, Thurso, Gatineau, Porta-ge-du-Fort and Joliette, for the transportation of wood chips and sawdust, on behalf of : Bois Laurentien Inc.; Les Produits Forestiers; Emeric Bergeron & Fils Ltée.Modification: The applicant requests that the following clause be added to its permit: General trucking - long distance - radius -St.Alexis and all points located within a radius of 30 miles from the limits of said locality, and return, for the transportation of goods.54697-0 Places d'affaires dans la Province Places of Business in the Province JACK BROWN Avis est donné que l'adresse, pour la province dc Québec, de « JACK BROWN » est 212, avenue Bloom-field - Outremont, Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54701-o Perreault & Rivet.JACK BROWN Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"MR.JACK BROWN\" is 212 Bloom-field Avenue - Outremont.Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54701-o Attorneys for the company.M.G.M.TRANSPORT CORPORATION Avis est donné que l'adresse, pour la province dc Québec, de la compagnie « M.G.M.TRANSPORT CORPORATION », permis No 22940-V est 212, avenue Bloomfield - Outremont, Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette.Paquette, 54702-o Perreault & Rivet.M.G.M.TRANSPORT CORPORATION Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"M.G.M.TRANSPORT CORPORATION\", permit No.22940-V is 212 Bloomfield Avenue -Outremont, Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54702-o Attorneys for the company.NESEL FAST FREIGHT INC.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Quebec, de la compagnie « NESEL FAST FREIGHT INC.», est 8200 de l'Industrie, Ville d'Anjou, P.Q.Téléphone: 353-1123.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54703-o Perreault & Rivet.NESEL FAST FREIGHT INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"NESEL FAST FREIGHT INC.\", is 8200 de l'Industrie, Ville d'Anjou, P.Q.Telephone: 353-1123.54703-o Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, Attorneys for the company. 6982 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3.',, 1973, Vol.105, No.17 NEW WOODBINE TRANSPORT (1968) LTD Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec de la compagnie « NEW WOODBINE TRANSPORT (1968) LTD.», permis No 16294-V est 200 ouest, rue St-Jacques, suite 900.Montréal (Québec) H2Y 1M1 Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54704-o Perreault & Rivet.NEW WOODBINE TRANSPORT (1968) LTD Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"NEW WOODBINE TRANSPORT (1968) LTD.\", permit No.16294-V is 200 St.James St.W., Suite 900, Montreal (Québec) H2Y 1M1 Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54704-o Attorneys for the company.SLACK TRANSPORT LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « SLACK TRANSPORT LTD.», permis No 17039-V est 212, rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 54705-o Perreault & Rivet.SLACK TRANSPORT LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"SLACK TRANSPORT LTD\", permit No.17039-V is 212 Bloomfield St.Outremont, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54705-o Attorneys for the company.AMBLER-COURTNEY LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Quebec, de la compagnie « AMBLER-COURTNEY LTD.», est: 2799 Montée St-Rémi, Dorval, Québec.Téléphone: 683-3936.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54800-o Perreault & Rivet.AMBLER-COURTNEY LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"AMBLER-COURTNEY LTD.\", is: 2799 Montée St.Rémi, Dorval City, Québec.Telephone: 683-3936.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54800-o Attorneys for the Company.BRADCO HOLDINGS INC.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « BRADCO HOLDINGS INC.», est: 2799, Montée St-Rémi, Dorval, Québec.Téléphone: 683-3936.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54801-o Perreault & Rivet.BRADCO HOLDINGS INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"BRADCO HOLDINGS INC.\", is: 2799 Montée St.Rémi, Dorval City, Québec.Telephone: 683-3936.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54801-o Attorneys for the Company.TRAVERSE M.S.S.LTEE Avis est donné que la compagnie « TRAVERSE M.S.S.LTEE » a une place d'affaires à Cap-aux-Meules, Ilcs-de-la-Madeleine, province de Québec, CP.245.Téléphone: 986-2214.Les procureurs de la requérante, Amyot, Lesage, Lesage, 54802-o Bernard & Lengvari.TRAVERSE M.S.S.LTEE Notice is given that \"TRAVERSE M.S.S.LTEE\" has a business office at Cap-aux-Meules, Magdalen Islands, Province of Québec, Post Office Box 245.Telephone: 986-2214.Amyot, Lesage, Lesage, Bernard & Lengvari, 54802 Attorneys for the applicant.ALDERSHOT CARRY-ALL SERVICES LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « ALDERSHOT CARRYALL SERVICES LTD.» permis no 16385^ est 8751 rue Orescent, ville d'Anjou, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 54826-0 Perreault & Rivet.ALDERSHOT CARRY-ALL SERVICES LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec of \"ALDERSHOT CARRY-ALL SERVICES LTD,\", permit No.16385-V is 8751 Crescent Street, Anjou, Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 54826-0 .Utorneys for the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2k novembre 1978, 105' année, n\" A7 6983 GEORGE HAROLD SELLECK Avis est donné que l'adresse de « GEORGE HAROLD SELLECK ».dans la province de Québec est située au numéro 4953, rue Bonny, appartement 5, Pierrefonds, Québec.G.H.Selleck.Spenceville, Ontario.54720 GEORGE HAROLD SELLECK Notice is given that the address for the Province of Québec of \"GEORGE HAROLD SELLECK\", is 4953 Bonny St.Apt.5, Pierrefonds, Québec.G.H.Selleck.Spenceville, Ontario.54720-o HURDMAN BROS.LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « HURDMAN BROS.LTD.», permis no 15829-V est 25, rue Joanisse, Hull, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Byers, Casgrain & Stewart.54827-0 Par: Jean Bazin.HURDMAN BROS.LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"HURDMAN BROS.LTD.\", permit No.15829-V is 25 Joanisse St., Hull, Province of Québec.Byers, Casgrain & Stewart, Per: Jean Bazin, 54827-0 Attorneys for the company.LIQUID CARGO LINES LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « LIQUID CARGO LINES LIMITED», permis No 16137-V est 485, Marien Street, Montréal East, Québec, téléphone: 645-7483.Le procureur de la compagnie, 54848-0 gérard corbeil.LIQUID CARGO LINES LIMITED Notice is given that the address, in the Province of Québec, of \"LIQUID CARGO LINES LIMITED\", permit No.16137-V.is 485 Marien Street, Montreal-East, Québec, Telephone: 645-7483.gérard corbeil, 5484S Attorney for the Company.LOU'S TRANSPORT CO.LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « LOU'S TRANSPORT CO.LIMITED », permis No.19006-V.est 72, Crémazie, Hull, Québec, téléphone: 771-5286.lie procureur de la compagnie, 54849-0 gérard corbeil.LOU'S TRANSPORT CO.LIMITED Notice is given that the address, in the Province of Québec, of \"LOU'S TRANSPORT CO.LIMITED\", permit No.19006-V, is 72 Crémazie, Hull, Québec, Telephone 771-5286.gérard corbeil, 54849 Attorney for the Company.PEPLOW TRANSPORT LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « PEPLOW TRANSPORT LIMITED » est 4970, Place de la Savane, Montréal, Québec.Le procureur de la compagnie, 54850-o gérard corbeil.PEPLOW TRANSPORT LIMITED Notice is given that the address, in the Province of Québec, of \"PEPLOW TRANSPORT LIMITED\" is 4970 Place de la Savane, Montreal, Québec.gérard corbeil, 54850 Attorney for the Company.TANK TRUCK TRANSPORT LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « TANK TRUCK TRANSPORT LIMITED », permis No.13353-V est 72, Crémazie, Hull, Québec, téléphone: 771-5286.TANK TRUCK TRANSPORT LIMITED Notice is given that the address, in the Province of Québec, of \"TANK TRUCK TRANSPORT LIMITED\", permit No.13353-V, is 72 Crémazie, Hull, Québec, Telephone: 771-5286.54851-0 Le procureur de la compagnie, gérard corbeil, 54851 Gérard Corbeil, Attorney for the Company. 6984_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.17 Succession Réjean Landry Avis est par les présentes donné que Dame Madeleine Gingras, ménagère, demeurant au 276 rue St-Joseph à Thetford-Mines, seule et unique héritière de son époux, feu Réjean Landry, journalier, demeurant au 14 est, rue Dumais à Thetford-Mines, aux termes du testament de ce dernier, reçu devant Me Laurent Drapeau, notaire, le 2 juillet 1958, a accepté la succession dudit Réjean Landry, sous vénéfice d'inventaire aux termes d'un acte exécuté devant Me Jean R.Gardner, notaire au 179 Notre-Dame sud, à Thetford-Mines, daté du 5 octobre 1973 et dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Thetford, à Thetford-Mines, le 9 octobre 1973.sous le numéro 71033.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant le notaire Jean R.Gardner et peut être consulté à ses bureaux, à l'adresse ci-dessus.Après deux mois du présent avis, la bénéficiaire paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Donné à Thetford-Mines, ce 31 octobre 1973.Le procureur.54700-O Jean R.Gardner, notaire.Estate of Réjean Landry Notice is hereby given that Mrs Madeleine Gingras, housewife, residing at 276 St.Joseph Street, in Thetford-Mines, sole heir of her husband, the late Réjean Landry, journeyman, residing at 14 Dumais Street East, Thetford-Mines.under the terms of the latter's last will, executed Me Laurent Drapeau, notary, on July 2, 1958, has accepted under benefit of inventory the estate of said Réjean Landry, under the terms of a deed executed before Me Jean R.Gardner, notary, at 179 Notre-Dame Street South, in Thetford-Mines, dated October 5, 1973, a copy of which was registered at the Thetford Registration Division Office, in Thetford-Mines, on October 9, 1973, under number 71033.An inventory of the estate of the deceased has been drawn up before Jean R.Gardner, notary, and may be examined at his office, at the aforementioned address.After two months following publication of the present notice, the beneficiary shall acquit the debtors as and when they present temselves, according to law.Given in Thetford-Mines, on this October 31st, 1973.Jean R.Gardner, notary, 54700 Attorney.Succession Yvon Perreault Avis public est donné que Pierre, Claude.Louisette, Luc, Dame Rosa Breton-Perreault, Dame Nicole Perreault-Lessard et Dame Huguette Perreault-Mcrcier ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Yvon Perreault, en son vivant domicilié à Ste-Ger-maine.Grand Rang, comté de Dorchester, suivant acte reçu devant Me Jules Fortin, notaire, à Lac Etchemin.comté de Dorchester, le 31 août 1973 et enregistré à Dorchester le 26 octobre 1973 sous le numéro 151.798.Donné le 31 octobre 1973.Le procureur.54721-o .Il les Fortin, notaire.Estate of Yvon Perreault Public notice is given that Pierre, Claude, Louisette, Luc.Mrs Rosa Breton-Perreault Mrs Nicole Perreault-Lessard and Mrs Huguette Perreault-Mercier have accepted under benefit of inventory the estate of Yvon Perreault, in his lifetime domiciled in Ste.Germaine, Grand Range.County of Dorchester, pursuant to a deed executed before Me Jules Fortin, notary, in Lac Etchemin, County of Dorchester, on August 31, 1973 and registered in Dorchester on October 26, 1973, under number 151.798.Given on October 31.1973.Jules Fortin, notary, 54721 Attorney.Succession Mounir Chanioun Avis est par les présentes donné que par acte d'acceptation reçu devant Me J.L.Bonin, notaire, à Joliette, le 2 novembre 1973, enregistré à Joliette, le 5 novembre 1973, sous le numéro 169693, Dame Ferial Farid, ménagère, tant personnellement qu'en qualité de tutrice à ses enfants mineurs: Alain et Richard Chamoun, et Monsieur Richard Dubreuil, ès-qualité de subrogé-tuteur auxdits enfants mineurs, ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession dudit Mounir Chamoun décédé sans testament le 3 décembre 1972.Le notaire, 375 boul.Manseau, Jean-Lin Bonin.Joliette.54814-0 Estate of Mounir Chamoun Notice is hereby given that by deed of acceptance passed before Mtre J.L.Bonin, notary, on November 2nd, 1973, a copy of which was registered in the Registration Division of Joliette, on November 5th, 1973, under number 169693, Mrs.Ferial Farid, housekeeper, as personnally as in her quality of tutrix to her minor children: Alain and Richard Chamoun, and Mr.Richard Dubreuil, in his quality of subrogate-tutor to said minor children, have accepted under the benefit of inventory the estate the said Mounir Chamoun, deceased without testament, on December 3rd, 1972.Jean-Lin Bonin, 375 boul.Manseau, Notary.Joliette.54814-0 Avis divers Miscellaneous Notices GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, '24 novembre 1973, 105' année, n° 47 .',9s.-, ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE VLLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED Avis est par les présentes donné que Maurice Babeux, de la Ville de Boueherville, District de Montréal, Province de Québec, s'adressera au Parlement du Canada, à sa présente session ou à la session suivante, afin de demander l'annulation d'un avis de dissolution relatif à la compagnie « ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE \u2014 ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED », donné le 17 juin 1968 et publié dans la Gazelle du Canada, le 22 juin 1968.Hull, ce 6e jour de septembre 1973.Les procureurs du pétitionnaire, 102 rue Principale, Martineau & Forget.Hull, P.Q.54810-47-4-o Ville de Montréal A vis de rachat Aux détenteurs des obligations payables en monnaie canadienne de l'émission désignée « Obligations 5J4% à fonds d'amortissement pour travaux publics, échéant le 1er janvier 1978 » de la Cité de Montréal, province dc Québec, Canada.AVIS.PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que la Ville de Montréal a l'intention de racheter et rachètera POUR FINS D'AMORTISSEMENT le 1er janvier 1974 conformément aux dispositions des obligations, les obligations suivantes de l'émission mentionnée ci-dessus, à 100% de leur .montant en principal plus l'intérêt couru à la date de rachat, à savoir: Numéros des obligations à coupons de 81,000 chacune portant le préfixe A, rachetables le 1er janvier 1974: 212550\t212555\t212557\t212558\t212559\t212566 212575\t212576\t212577\t212594\t212605\t212619 212895\t212896\t212905\t212906\t212909\t212910 212960\t212978\t212979\t212995\t213000\t213018 213165\t213169\t213171\t213172\t213173\t213188 213361\t213362\t213366\t213369\t213370\t213378 213432\t213436\t213443\t213445\t213450\t213460 213650\t213655\t213973\t213976\t213982\t214066 214089\t214093\t214096\t214098\t214108\t214120 214218\t214224\t214229\t214240\t214242\t214250 214265\t214270\t214284\t214285\t214308\t214309 214473\t214477\t214571\t215204\t215206\t215207 215261\t215264\t215273\t215403\t215421\t215473 215511\t215542\t215543\t215555\t215564\t215677 215720\t215721\t215734\t215744\t215749\t215752 215828\t215833\t215837\t215S39\t215846\t215848 215960\t215963\t215964\t216031\t216056\t216059 216084\t216085\t216093\t216097\t216169\t216510 216683\t216826\t216827\t216833\t216915\t216916 216934\t216936\t216938\t216945\t216949\t216957 217049\t217051\t217052\t217053\t217059\t217064 217087\t217106\t217119\t217897\t217908\t217986 ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED Notice is by these presents given that Maurice Ba-beux.of the City of Boucherville, District of Montreal, Province of Québec, will address himself to the Parliament of Canada, at the present session or the following session, to request the annulation of a notice of dissolution in regard to the company \"ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE \u2014 ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED, given the 17th day of June 1968.and published in the Canada Gazelle, June 22nd, 1968.Hull, this 6th day of September 1973.Martineau & Forget, 102 Main Street, Attorneys for the petitioner.Hull, P.Q.54810-47-4-o City of Montreal Notice of redemption To the holders of Debentures payable in Canadian Currency of the issue designated \"5J4% Sinking Fund Debentures for Public Works, due January 1, 1978\" of the City of Montreal.Province of Québec, Canada.PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Citv of Montreal intends to and will redeem FOR SINKING FUND PURPOSES on January 1, 1974, pursuant to the provisions of the debentures, the following debentures of the above-mentioned issue at 100% of principal amount plus accrued interest to the redemption date, namely: Numbers of the Coupon Debentures of $1,000 each, bearing the prefix A, redeemable on January 1, 1974: 212568\t212569\t212570\t212572\t212573\t212574 212624\t212627\t212633\t212634\t212816\t212838 212915\t212933\t212934\t212947\t212954\t212958 213132\t213134\t213148\t213150\t213154\t213159 213261\t213354\t213355\t213357\t213358\t213360 213379\t213411\t213412\t213414\t213417\t213420 213464\t213469\t213472\t213477\t213483\t213486 214069\t214074\t214076\t214082\t214086\t214087 214122\t214125\t214138\t214199\t214204\t214209 214252\t214255\t214258\t214262\t214263\t214264 214431\t214452\t214454\t214455\t214459\t214469 215208\t215209\t215211\t215216\t215218\t215258 215476\t215480\t215500\t215503\t215504\t215510 2156S2\t215685\t215690\t215691\t215694\t215700 215753\t215756\t215761\t215762\t215763\t215764 215851\t215852\t215860\t215954\t215955\t215959 216064\t216068\t216072\t216075\t216076\t216077 216513\t216526\t216568\t216577\t216611\t216672 216920\t216921\t216926\t216927\t216928\t216930 216959\t217011\t217016\t217017\t217028\t217042 217065\t217067\t217073\t217076\t217080\t217081 217995\t218707\t218714\t218715\t218717\t218721 6986 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 218722\t218723\t218726\t218727\t218746\t218748 218944\t218963\t218964\t218971\t218978\t218979 219009\t219011\t219014\t219015\t219016\t219018 219035\t219042\t219058\t219060\t219065\t219069 219537\t219667\t219668\t219673\t219742\t219743 219831\t219836\t219838\t219840\t219844\t219846 219872\t219882\t219883\t219884\t219888\t219889 219909\t219913\t219919\t219920\t219925\t219926 221207\t221208\t221210\t221211\t221216\t221217 221386\t221401\t221406\t221407\t221409\t221413 221435\t221440\t221605\t221608\t221675\t221676 221793\t221794\t221795\t221796\t221797\t221801 221817\t221829\t221832\t221842\t221860\t221867 221918\t221924\t221930\t221948\t221950\t221954 221993\t222026\t222036\t222038\t222049\t222051 222076\t222077\t222083\t222086\t222087\t222091 222260\t222261\t222263\t222266\t222267\t222271 222302\t222304\t222306\t222312\t222313\t222314 222340\t222800\t222802\t222809\t222812\t222821 222838\t222840\t222842\t222855\t222857\t222858 222934\t222938\t222941\t222942\t222943\t222945 222976\t222979\t222980\t222983\t222987\t222990 223065\t223066\t223070\t223071\t223073\t223075 223116\t223126\t223154\t223158\t223178\t223181 Les obligations ainsi rappelées pour rachat deviendront dues et payables et seront payées, au choix du détenteur, en monnaie légale du Canada, au bureau principal de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Nationale, de La Banque Royale du Canada ou de La Banque Provinciale du Canada, situé dans les villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, sur présentation et remise des obligations portant les numéros mentionnés ci-dessus, avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er janvier 1974 attachés.Les obligations immatriculées quant au principal doivent être accompagnées de procurations pour leur transfert dûment signées en blanc.Avis public est aussi par les présentes donné que l'intérêt sur le montant en principal des obligations présentement appelées pour paiement cessera dc s'accroître le et après le 1er janvier 1974.Daté à Montréal, ce deuxième jour de novembre 1973.Ville de -Montréal, Roger Bélanger, 54793-0 Directeur des finances.Ville de Montréal .I dû de rachat Aux détenteurs des obligations payables en monnaie canadienne dc l'émission désignée « Obligations 5l4Vo à fonds d'amortissements pour améliorations locales, échéant le 15 janvier 1978 » de la Cité de Montréal, province dc Québec, Canada.AVIS PUBLIC EST PAR LES PRESENTES DONNÉ que la Ville dc Montréal a l'intention dc racheter et rachètera POUR FINS D'AMORTISSEMENT le 15 janvier 1974 conformément aux disposi- 218750\t218751\t218767\t218906\t218910\t218931 218981\t218984\t218986\t219001\t219002\t219007 219019\t219020\t219022\t219026\t219029\t219032 219074\t219081\t219083\t219084\t219085\t219536 219768\t219769\t219814\t219816\t219828\t219829 219850\t219852\t219858\t219866\t219867\t219870 219895\t219896\t219898\t219899\t219901\t219908 219929\t219934\t219935\t220140\t220141\t221203 221219\t221223\t221224\t221226\t221230\t221234 221419\t221420\t221422\t221429\t221432\t221433 221680\t221683\t221687\t221688\t221786\t221790 221804\t221806\t221808\t221809\t221815\t221816 221870\t221906\t221910\t221912\t221914\t221916 221956\t221958\t221960\t221962\t221969\t221974 222052\t222056\t222062\t222065\t222069\t222071 222099\t222100\t222155\t222250\t222255\t222257 222275\t222285\t222287\t222292\t222294\t222296 222318\t222320\t222322\t222329\t222337\t222339 222824\t222827\t222829\t222834\t222835\t222836 222859\t222870\t222884\t222887\t222924\t222925 222955\t222956\t222959\t222966\t222969\t222973 222991\t222994\t222996\t222999\t223010\t223046 223078\t223087\t223088\t223089\t223101\t223111 223185\t223187\t223188\t223190\t\t Debentures to be so redeemed will become due and payable and will be paid, at the option of the holder, in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of Montreal, Bank Canadian National, The Royal Bank of Canada or The Provincial Bank of Canada located in the cities of Montreal, Toronto, Halifax, Saint John.N.B.Québec, Winnipeg or Vancouver, Canada, upon presentation and surrender of Debentures bearing the above-mentioned numbers with all coupons maturing after January 1.1974 attached.Debentures registered as to principal must be accompanied by assignments for transfer powers duly executed in blank.Public notice is also hereby given that all interest on the principal amount of the Debentures presently called for pavmcnt will cease to accrue from and after January 1.1974.Dated at Montreal, this second day of November, 1973.City of Montreal.Roger Bélanger, 54793 Director of Finance.City of Montreal Notice of redemption To the holders of Debentures payable in Canadian Currency of the issue designated \"514% Sinking Fund Debentures for Local Improvements, due January 15, 1978\" of the City of Montreal, Province of Québec, Canada.PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Montreal intends to and will redeem FOR SINKING FUND PURPOSES on January 15, 1974, pursuant to the provisions of the debentures, the following GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n\" L7 6987 tions des obligations, les obligations suivantes de l'émission mentionnée ci-dessus, à 100% dc leur montant en principal plus l'intérêt couru à la date de rechat, à savoir: Numéros des obligations à coupons de $1,000 chacune portant le préfixe A, rachetables le 15 janvier 1974: 223251\t223253\t223259\t223260\t223265\t223267 223314\t223330\t223331\t223339\t223342\t223349 223370\t223374\t223378\t223380\t223385\t223388 223415\t223416\t223430\t223431\t223433\t223434 223498\t223531\t223532\t223535\t223543\t223545 223707\t223708\t223827\t223828\t223830\t223852 223998\t223999\t224000\t224001\t224002\t224005 224024\t224025\t224026\t224027\t224035\t224036 224117\t224118\t224120\t224121\t224122\t224123 224179\t224181\t224182\t224486\t224487\t224488 224502\t224505\t224506\t224507\t224508\t224509 224522\t224524\t224528\t224529\t224531\t224543 224550\t224551\t224552\t224555\t224556\t224559 224612\t224613\t224614\t224615\t224616\t224634 224649\t224655\t224656\t224657\t224658\t224659 224678\t224680\t224682\t224683\t224684\t225713 226226\t226227\t226230\t226233\t226234\t226235 226278\t226279\t226280\t226285\t226286\t226287 227184\t227185\t227186\t227203\t227300\t227304 227951\t228061\t228064\t228081\t228082\t228596 228612\t228614\t228677\t228678\t228679\t228680 228794\t228795\t228796\t228798\t228805\t228806 229031\t229033\t229034\t229035\t229037\t229124 229146\t229161\t229164\t229165\t229166\t229167 229180\t229181\t229183\t229187\t229188\t229193 229793\t229794\t229795\t229832\t229833\t229834 229859\t229863\t229865\t229915\t229917\t229918 230002\t230003\t230044\t230045\t230052\t230055 230079\t230083\t230084\t230086\t230093\t230094 230190\t230192\t\t\t\t Les obligations ainsi rappelées pour rachat deviendront ducs et payables et seront payées, au choix du détenteur, en monnaie légale du Canada, au bureau principal de la Banque dc Montréal, de la Banque Canadienne Nationale, de La Banque Royale du Canada ou de La Banque Provinciale du Canada, situé dans les villes de Montréal, Toronto.Halifax.Saint John, N.B.Québec, Winnipeg ou Vancouver.Canada, sur présentation et remise des Obligations portant les numéros mentionnés ci-dessus, avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 15 janvier 1974 attachés.Les obligations immatriculées quant au principal doivent être accompagnées de procurations pour leur transfert dûment signées en blanc.Avis public est aussi par les présentes donné que l'intérêt sur le montant en principal des obligations pré-\u2022.entement appelées pour paiement cessera de s'accroître le et après le 15 janvier 1974.Daté à Montréal, ce deuxième jour dc novembre 1973.Ville de Montréal.Roger Bélanger, 54794-0 Directeur des finances.debentures of the above-mentioned issue at 100% of principal amount plus accrued interest to the redemption date, namely: Numbers of the Coupon Debentures of 81,000 each, bearing the prefix A, redeemable on January 15, 1974: 223269\t223275\t223279\t223280\t223309\t223312 223353\t223355\t223357\t223358\t223359\t223362 223390\t223397\t223398\t223401\t223404\t223412 223435\t223436\t223472\t223475\t223482\t223483 223546\t223548\t223700\t223704\t223705\t223706 223857\t223858\t223868\t223869\t223994\t223996 224007\t224008\t224016\t224018\t224019\t224021 224038\t224039\t224042\t224043\t224044\t224045 224124\t224125\t224156\t224175\t224176\t224178 224490\t224491\t224492\t224493\t224496\t224498 224515\t224516\t224517\t224519\t224520\t224521 224544\t224545\t224546\t224547\t224548\t224549 224561\t224577\t224578\t224584\t224596\t224597 224636\t224638\t224639\t224640\t224641\t224648 224660\t224661\t224666\t224670\t224672\t224677 225717\t225722\t225723\t225975\t225976\t226160 226250\t226251\t226272\t226274\t226276\t226277 226288\t226289\t226320\t226322\t226323\t226328 227308\t227311\t227324\t227836\t227947\t227948 228598\t228599\t228605\t228608\t228609\t228610 228756\t228786\t228789\t228791\t228792\t228793 228809\t228810\t228814\t228815\t228816\t228818 229126\t229127\t229139\t229140\t229144\t229145 229168\t229169\t229176\t229177\t229178\t229179 229195\t229717\t229719\t229787\t229788\t229790 229836\t229838\t229839\t229848\t229855\t229857 229954\t229959\t229967\t229969\t229973\t229999 230059\t230062\t230068\t230074\t230075\t230078 230095\t230096\t230097\t230099\t230184\t230188 Debentures to be so redeemed will become due and payable and will be paid, at the option of the holder, in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of Montreal.Bank Canadian National, The Royal Bank of Canada or The Provincial Bank of Canada located in the cities of Montreal, Toronto, Halifax, Saint John.N.B.Québec, Winnipeg or Vancouver, Canada, upon presentation and surrender of Debentures bearing the above-mentioned numbers with all coupons maturing after January 15, 1974 attached.Debentures registered as to principal must be accompanied by assignments for transfer powers duly executed in blank.Public notice is also hereby given that all interest on the principal amount of the debentures presently called for pavmcnt will cease to accrue from and after Januarv 15, 1974.Dated at Montreal, this second dav of November, 1973.City of Montreal.Roger Bélanger.54794-o Director of Finance. 6988 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November gl, 1973, Vol.105, No.47 Arrêté en conseil Order in Council Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 4071-73 Québec, le 8 novembre 1973.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant le changement du nom dc la commission scolaire numéro 4.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation : Que le nom de la commission scolaire qui a autorité sur '< La Municipalité scolaire du Centre-Sud de Montréal » soit changé de celui de « La Commission scolaire du Sault-Saint-Louis, » et ce, conformément à l'article 90 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du conseil exécutif, 54847-0 Julien Chouinard.Order in Council Executive Council Chamber Number 4071-73 Québec, November 8, 1973.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Respecting the change of name of School Board number 4.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That the name of the School Board which has authority over The School Municipality of Centre-Sud de Montréal be changed to that of \"The Sault-St.Louis School Board\", the foregoing in conformity with section 90 of the Education Act, Revised Statutes.1964, Chapter 235.Julien Chouinard, 54847 Clerk of the Executive Council.Ministère de l'Éducation Department of Education La Commission scolaire du Sault-Saint-Louis Avis est par la présente donné que le nom de la commission scolaire numéro 4 qui a autorité sur la Municipalité scolaire du Centre-Sud de Montréal, a été changé en celui de « La Commission scolaire du Sault-Saint-Louis » ; et ce, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 4071-73 du 8 novembre 1973, dont le texte suit: Concernant le changement du nom de la commission scolaire numéro 4.Que le nom de la commission scolaire qui a autorité sur « La Municipalité scolaire du Centre-Sud de Montréal » soit changé en celui de « La Commission scolaire du Sault-Saint-Louis », et ce, conformément à l'article 90 de la Loi de l'instruction publique.Statuts refondus.1964.chapitre 235.Ce changement prendra effet huit (8) jours suivant la date de la présente publication.Le 19 novembre 1973.Le ministre de l'éducation, 54847-0 François Cloutier.Rivicre-du-Loup Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire des Basques, les lots 1 à 42 du rang Est, du cadastre officiel de St-Jean-Baptiste-de-ITsIc-Verte, pour les annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire de Rivière-du-Loup.I*e ministre de l'éducation, 54847-0 François Cloutier.The Sault-St.Louis School Board Notice is hereby given that the name of School Board number 4, which has authority over the School Municipality of Centre-Sud de Montréal, has been changed to that of \"The Sault-St.Louis School Board\"; the foregoing pursuant to Order in Council number 4071-73 dated November 8.1973, which reads as follows: Respecting the change of name of School Board number 4.That the name of the School Board which has authority over the \"School Municipality of Centre-Sud de Montréal\" be changed to that of \"The Sault-St.Louis School Board\", the foregoing in conformity with section 90 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.This change shall take effect eight (8) days following the date of this publication.November 19.1973.François Cloutier, 54847 Minister of Education.Rivière-du-Loup Request is hereby made to detach from the School Municipality of Basques, lots 1 to 42 of the East Range on the official cadastre of St.Jean-Baptistc-de-ITsle-Verte to annex them, for catholics only, to the School Municipality of Rivière-du-Loup.François Cloutier, 54847 Minister of Education. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, 105' année, n\" L7 6989 Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications Joseph-Albert-Yvon Bourgea Avis est par les présentes donné que Monsieur Joseph-Albert-Yvon Bourgea résidant et domicilié au 1329.rue Sud à Cowansville, district de Bedford, province de Québec s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour obtenir un décret changeant son nom de Monsieur Joseph-Albert-Yvon Bourgea à celui de Monsieur Joseph-Albert-Yvon Lacoste.Cowansville.ce 8 novembre 1973.Le procureur du requérant, 54667-46-2-0 André Bachand.Lucinc Desbiens Avis est par les présentes donné que Lucine Desbiens résidant au numéro 214, rue Champagnat, Aima, district de Roberval, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à Lucille Desbiens.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Aima, le 18 octobre 1973.Les avocats de la requérante, 54608-46-2-o Gauthier & Maltais.Nelson Lafond Avis est donné par les présentes que Nelson Lafond.vendeuse, domiciliée au 3333 Côte-Ste-Catherine, dans les ville et district de Montréal, présentera une requête au ministre de la justice afin de changer son nom en celui dc Nelsone Rivard, ledit changement de nom devra aussi profiter à son fils Stéphane Lafond dont le nom sera changé en celui de Stéphane Rivard.Montréal, ce 23 octobre 1973.Les procureurs de la requérante.54609-46-2-o Parent.Laforest & Girahd.Irving Mazer Avis est donné que Irving Mazer domicilié à 2227 rue Goyer à Montréal, présentera au ministre de la justice une requête afin que son nom devienne Irving Mazer Miller sur les registres de l'état civil.Montréal, le 9 novembre 1973.Le procureur du requérant.54661-46-2-0 Joseph Helal, c.r.Barry Katz Avis est donné que Barry Katz, homme d'affaires, domicilié au 1205 rue Bishop, apt.7, Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Barry Robert Kates.Le procureur de la compagnie, 54804-47-2-o Philippe Clément, b.a., ll.l.Joseph-Albert-Yvon Bourgea Notice is hereby given that Mister Joseph-Albert-Yvon Bourgea residing and domiciled at 1329, South Street, in Cowansville.district of Bedford, Province of Québec will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mister Joseph-Albert-Yvon Bourgea to Mister Joseph-Albert-Yvon Lacoste.Cowansville, November 8, 1973.André Bachand, 54667-46-2-0 Attorney for the petitioner.Lucine Desbiens Notice is hereby given that Lucine Desbiens, residing at 214 Champagnat St., Alma, district of Roberval, will petition the Lieutenant-Gouvernor in Council for permission to change his name to \"Lucille Des-biens\".This change will not effect any person else than the applicant.Alma.October 18th, 1973.Gauthier & Maltais, 54608-46-2-o Attorneys for Applicant.Nelson Lafond Notice is hereby given that Nelson Lafond, saleswoman, domiciled at 3333 Côte-Ste-Catherine, in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Justice to change her name to Nelsone Rivard, said change of name to benefit to her son, Stéphane Lafond, which name will be changed to Stéphane Rivard.Montreal, October 23rd.1973.Parent.Laforest & Girard.54609-46-2-o Attorneys for Petitioner.Irving Mazer Notice is given that Irving Mazer of 2227 Goyer Street, Montreal, is applying to the Minister of Justice in order to have his name appear as Irving Mazer Miller on the registers of Civil Status.Montreal, November 9th, 1973.Joseph Helal, q.c., 54661-46-2-0 Attorney for Petitioner.Barry Katz Notice is given that Barry Katz, businessman, domiciled at 1205 Bishop Street, Apt.7, Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Barry Robert Kates.Philippe Clément, b.a., ll.l., 54804-47-2 Attorney for the Company. 6990 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 Stephen (Istvan) Beck Avis est par les présentes donné que Stephen (Istvan) Beck domicilié au 3140, boulevard Edouard Montpetit, dans la ville et district de Montréal, province de Québec, s'adressera à l'assemblée nationale du Québec, au cours de la prochaine session pour obtenir l'adoption d'une loi autorisant le Barreau de la province de Québec à l'admettre à l'exercice de la profession d'avocat.Québec, ce 5e jour de novembre 1973.Le procureur du requérant, 54607-46-2-o Laszlo Szemenyei.Jack Albert Smith Avis est par les présentes donné que Jack Albert Smith, commis, domicilié à 119 Lakeshore Drive, ville de Rawdon, district de Joliette, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom pour celui de Jack Albert Hillrich.Montréal, ce 6 novembre 1973.Les procureurs du requérant, McDougall.Hemens, Harris.54610-46-2-o Thomas, Mason & Schweitzer.Euclide Cyrille Cauchon Avis est par les présentes donné que Euclide Cyrille Cauchon, fils de Joseph Cauchon et de Juliette Bertrand, domicilié au 2825 rue Jeanne d'Arc à Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour un décret changeant son nom de Euclide Cyrille Cauchon à celui de Euclide Cyrille Laverdière, et d'y exercer tous ses droits sous ce nouveau nom.Montréal, ce 8 novembre 1973.Mes Giroux & Even, avocats.7244, St-Denis, Montréal, P.Q.54687-46-2-o Jean-Paul Jacques Avis est donné que Jean-Paul Jacques, courrier, domicilié au 3, rue Langlois.Robertsonville, district de Mégantic, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Jean-Paul Vaillancourt.Ce changement de nom bénéficiera aussi à son épouse.Rachel Gagné, de la même adresse.Thetford-Mines.ce 1er novembre 1973.Les procureurs du requérant, 54719-47-2-0 Beaudoin & Paradis.David André CIcrin Avis est par les présentes donné que, David André Clérin, domicilié au 2565, rue Gregg, Stc-Foy, a présenté une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de David André de Clérin.Québec, le 25 octobre 1973.Les procureurs du requérant, Joi.i-Coeur, 54820-47-2-0 Joli-Ooei'h & Mathieu.Stephen (Istvan) Beck Notice is hereby given that Stephen (Istvan) Beck domiciled at 3140 boulevard Edouard Montpetit, in the city and district of Montreal, Province of Québec, wishes to present a petition to the Legislative Assembly of the Province of Québec at the next session to pass an Act that the Bar of the Province of Quebec be authorized to admit him to the practice of the profession of advocate in the Province of Québec.Québec, 5th of November, 1973.Laszlo Szemenyei, 54607-46-2-0 Attorney for Petitioner.Jack Albert Smith Notice is hereby given that Jack Albert Smith, Clerk, domiciled at 119 Lakeshore Drive, in the Town of Rawdon.District of Joliette, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Jack Albert Hillrich.Montreal, November 6, 1973.McDougall, Hemens, Harris, Thomas, Mason & Schweitzer, 54610-46-2-o Attorneys for Applicant.Euclide Cyrille Cauchon Notice is hereby given that Euclide Cyrille Cauchon, son of Joseph Cauchon and Juliette Bertrand, domiciled and residing at 2825 Jeanne d'Arc, in Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Euclide Cyrille Cauchon to Euclide Cyrille Laverdière and that he may use of all his wrights under his new name.Montreal, November the 8th, 1973.Mes Giroux & Even, lawyers.7244 St.Denis, Montreal, P.Q.54687-46-2-0 Jean-Paul Jacques Notice is given that Jean-Paul Jacques, mailman, residing at 3 Langlois Street, Robertsonville, district of Megantic, will petition the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Jean-Paul Vaillancourt.The change of name shall benefit his wife, Rachel Gagné of the same address.Thetford-Mines, November 1, 1973.Beaudoin & Paradis, 54719-47-2-0 Attorneys for the petitioner.David André Clérin Notice is hereby given that David André Clérin, domiciled at 2565 Gregg Street, Ste.Foy, has presented a petition to the Minister of Justice in order to change his name to that of David Andre de Clérin.Québec, October 25, 1973.Joli-Coeur, Joli-Coeur & Mathieu, 54820-47-2 Attorneys for the applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U novembre 1973, 105' année, n' 17 6991 Demitrios Skoularinos Avis est par les présentes donné que Demitrios Skoularinos, restaurateur, du 6940, avenue Fielding, appartement 702, Montréal (Québec), présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom en celui de James Schoolarinos, lequel changement sera également applicable à son épouse, dame Jeanne Ellen Lavallée.Montréal, ce 8e jour de novembre 1973.Les procureurs dc la compagnie.Marks, Shapiro, Hoffman.54671-46-2 Green & Beinhaker.Demitrios Skoularinos Notice is hereby given that Demitrios Skoularinos, Rcstaurantcur, of 6940 Fielding Avenue, Apartment 702, Montreal, Québec, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council to change his name to James Schoolarinos, which change will also benefit his wife, Dame Jeanne Ellen Lavallée.Montreal, this 8th day of November.1973.Marks, Shapiro.Hoffman.Green & Beinhaker, 54671-46-2-0 Attorneys for Applicant.Lucien Roland Clérin Avis est par les présentes donné que, Lucien Roland Clérin, domicilié au 2565 rue Gregg, Ste-Foy, a présenté une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Lucien Roland de Clérin, ledit changement devant affecter l'épouse du requérant (née Claudette L.Excoffon), ainsi que ses enfants mineurs Pierre Raymond, André Daniel et Esther Claudette, étant tous domiciliés au même endroit que le requérant.Québec, le 25 octobre 1973.Les procureurs du requérant, JoLI-COEUR, 54821-47-2-0 Joli-Coeur & Mathieu.Lucien Roland Clérin Notice is hereby given that Lucien Roland Clérin, domiciled at 2565 Gregg Street, Ste.Foy, has presented a petition to the Minister of Justice in order to change his name to that of Lucien Roland de Clérin, said change shall also benefit the wife of the applicant (née Claudette L.Excoffon), as well as his minor children Pierre Raymond, André Daniel and Esther Claudette, all being domiciled at the same address as the applicant.Québec, October 25, 1973.joli-coeur, Joli-Coeur & Mathieu, 54821-47-2 Attorneys for the applicant.Gustave Lengyel Avis est par les présentes donné que Gustave Lengyel, mieux connu sous le nom d'Alexandre G.Lengyel, domicilié au 531, 83e Avenue, à Chomedey, Ville de Laval, province de Québec, a transmis au ministre de la justice une requête demandant que son nom soit changé de Gustave Lengyel à Alexandre Gustave Lengyel.Aucune autre personne ne sera affectée par ce changement de nom.Laval, ce 13e jour de novembre 1973 Les avocats du requérant.54822-47-2-o Pion & Wolke.Gustave Lengyel Notice is hereby given that Gustave Lengyel, better known under the name of Alexandre G.Lengyel, residing at 531, 83rd Avenue, in Chomedey, City of Laval, Province of Québec, has transmitted to the Minister of Justice a petition requesting the change of his name from Gustave Lengyel to Alexandre Gustave Lengyel.This change of name will affect no other person.Laval, this 13th day of November 1973.Pion & Wolfe, 54822-47-2-0 Attorneys for the petitioner.Flore Paradis Avis vous est donné que Flore Paradis, technicienne dentaire, domiciliée et résidant au 2045 rue Bishop, appartement 10, dans les ville et district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Danielle Paradis.Montréal, ce 16 novembre 1973.Flore Paradis Notice is given that Flore Paradis, Dental Technician, domiciled and residing at 2045 Bishop Street, Apt.10, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to that of Danielle Paradis.Montreal, November 16th, 1973.Les procureurs de la requérante.54823-47-2-0 Boisclaih, Lamoureux & Brizard, Boisclair, Lamoureux & Brizard, 54823-47-2-0 Attorneys for the Petitioner. 6992 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21,, 1973, Vol.105, No.1,7 Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name Granted Act Joseph Claude Jean Bernier Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4031 du 8 novembre 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph-Claude-Jean-Marie Rivest en celui de Joseph Claude Jean Bernier.Québec, le 14 novembre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54795-0 Robert Normand, c.r.Samuel Granat Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4032 du S novembre 1973, d'effectuer le changement de nom de Szmul Granatsztajn en celui de Samuel Granat.Québec, le 14 novembre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54795-0 Robert Normand, c.r.Joseph Ronald Maguire Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4033 du 8 novembre 1973, d'effectuer le changement de nom de Joseph Ronald Philips en celui de Joseph Ronald Maguire.Québec, le 14 novembre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54795-0 Robert Normand, c.r.Joseph Thomas Maguire Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4034 du 8 novembre 1973, d'effectuer le changement de nom dc Joseph Thomas Philip en celui de Joseph Thomas Maguire.Québec, le 14 novembre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54795-0 Robert Normand, c.r.Ruben Robert Mazin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 4035 du 8 novembre 1973, d'effectuer le changement de nom de Rouben Imzayin en celui de Ruben Robert Mazin.Québec, le 14 novembre 1973.Le sous-ministre de la justice, 54795-o Robert Normand, c.r.Joseph Claude Jean Bernier It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Claude-Jean-Marie Rivest to that of Joseph Claude Jean Bernier by order number 4031, dated November 8, 1973.Québec, November 14, 1973.Robert Normand, q.c, 54795 Deputy Minister of Justice.Samuel Granat It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Szmul Granatsztajn to that of Samuel Granat by order number 4032, dated November 8, 1973.Québec, November 14, 1973.Robert Normand, q.c, 54795 Deputy Minister of Justice.Joseph Ronald Maguire It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Ronald Philips to that of Joseph Ronald Maguire by order number 4033, dated November 8, 1973.Québec, November 14, 1973.Robert Normand, q.c, 54795 Deputy Minister of Justice.Joseph Thomas Maguire It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Thomas Philip to that of Joseph Thomas Maguire, by order number 4034, dated November 8, 1973.Québec, November 14, 1973.Robert Normand, q.c, 54795 Deputy Minister of Justice.Ruben Robert Mazin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Rouben Imzayin to that of Ruben Robert Mazin by order number 4035, dated November 8, 1973.Québec, November 14, 1973.Robert Normand, q.c., 54795 Deputy Minister of Justice.Sièges sociaux Head Offices L1ZMAX HOLDING CORP.La compagnie « LIZMAX HOLDING CORP.donne avis qu'elle a transféré son siège social de Mont-tréal à Lasalle.Le secrétaire, Pierre Hogue.54835 11469-60 LIZMAX HOLDING CORP.Notice is given that \"LIZMAX HOLDING CORP.\" has transferred its head office from Montreal, to Lasalle.Pierre Hogue, Secretary.54835-0 11469-60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U novembre 1973, 105' année, «° L7 6993 LOUIS FOODS LTD.ALIMENTS LOUIS LTEE La compagnie « LOUIS FOODS LTD.\u2014 ALI-MENTS LOUIS LTEE » donne avis qu'elle a transféré son siège social de Weedon à Montréal.Le secrétaire, Murray McBain*.54750 1405-70 LOUIS FOODS LTD.ALIMENTS LOUIS LTEE Notice is given that \"LOUIS FOODS LTD.\u2014 ALIMENTS LOUIS LTEE\" has transferred its head office from Weedon to Montreal.Murray McBain, Secretary.54750-o 1405-70 ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE STE-AGATHE-DES MONTS Avis est par les présentes donné que la Corporation « ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE STE-AGATHE-DES-MONTS », constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 11 octobre 1973 et ayant son siège social à Ste-Agathe, district judiciaire de Terrebonne, a établi son bureau principal au numéro R.R.2, C.P.34, à Ste-Agathe-des-Monts, comté de Terrebonne.A compter du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son bureau principal.Donné à Ste-Agathe, ce 27e jour d'octobre.1973.Le président, 54751-0 Claude Huppé.ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE STE-AGATHE-DES MONTS Notice is hereby given that \"ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE STE-AGATHE-DES-MONTS\", is incorporated by Letters Patent dated October 11, 1973 issued pursuant to the provisions of Part III of the Companies Act of the Province of Québec and having its head office in the city of Ste-Agathe County of Terrebonne, has established its office at R.R.2, C.P.34, Ste-Agathe-des-Monts.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Corporation as being the head office of the Company.Dated at Ste-Agathe, this 27th day of October 1973.Claude Huppé, 54751-0 President.ASSOCIATION PROVINCIALE DES INSTITUTIONS POUR ENFANTS Avis est donné que la compagnie « ASSOCIATION PROVINCIALE DES INSTITUTIONS POUR ENFANTS », constituée en corporation selon la 3e partie de la Loi des compagnies en date du 5e jour du mois de juin 1964, et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'au 25 avril 1973 au 4824 rue Côte des Neiges, l'a transporté au 65 est de la rue Sherbrooke, suite 110.À compter du 25 avril 1973, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 30e jour de juillet 1973.La secrétaire, Elizabeth Pellerin.54752-0 2253-64 LES ATELIERS WARWICK LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « LES ATELIERS WARWICK LTEE » constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies (Québec) par lettres patentes émises le 29 août 1973 a établi son bureau principal au 27.rue Hôtel de ville, à Warwick, district d'Arthabaska, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Warwick, ce 19e jour d'octobre 1973.Président.54753-0 Richard Fortieh.ASSOCIATION PROVINCIALE DES INSTITUTIONS POUR ENFANTS Notice is given that \"ASSOCIATION PROVINCIALE DES INSTITUTIONS POUR ENFANTS\", incorporated under Part III of the Companies Act on the 5th day of June, 1964, and having its head office in the City of Montreal, where its office was located until April 25, 1973, at 4824 Côte des Neiges Street, has transferred said office to 65 Sherbrooke Street East, Suite 110.From April 25, 1973, the said office shall be considered by the Company as its head office.Given in Montreal, this 30th day of July, 1973.Elizabeth Pellerin, Secretary.54752 2253-64 LES ATELIERS WARWICK LTEE Notice is hereby given that \"LES ATELIERS WARWICK LTEE\" incorporated under Part I of the Companies Act (Québec) by letters patent dated August 29th, 1973 has established its head office at number 27.Hotel de ville Street, Warwick, district of Ar-thabaska.Province of Québec, From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being its head office.Given at Warwick, Que., this 19th day of October 1973.Richard Fortier, 54753-0 President. 6994 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November SA, 1973, Vol.105, No.A7 RESTAURANT DELICES BAR-B INC.Avis est donné que la compagnie « RESTAURANT DELICES BARB INC.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 31 août 1973 et ayant son siège social dans la ville de Brossard a établi son bureau au numéro 6325 boulevard Taschereau.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 5e jour de novembre 1973.La secretaire, 54754-0 Barbara Wyngaert.RESTAURANT DELICES BAR-B INC.Notice is hereby given that the \"BAR-B DELIGHT RESTAURANT INC.\" company, incorporated by letters patent on the 31st day of August 1973, and having its head office in the City of Brossard.has established its office at number 6325 Taschereau Boulevard.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 5th day of November 1973.Barbara Wyngaert, 54754-0 Secretary.PIERRE BELLEFELTLLE ASSURANCE INC.La compagnie « PIERRE BELLEFEUILLE ASSURANCE INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1524, rue Jacques Lemaistre, Montréal, au numéro 5642, boulevard Léger.Montréal-Nord.La secrétaire, Pierrette Bellefeuille.54755-0 714030 PIERRE BELLEFEUILLE ASSURANCE INC.Notice is given that \"PIERRE BELLEFEUILLE ASSURANCE INC.\" has transferred its head office from 1524 Jacques Lemaistre Street, Montreal, to 5642 Léger Boulevard, Montreal-North.Pierrette Bellefeuille, Secretary.54755 714030 CENTRE DE DECORATION BELOEIL LTEE Avis est donné que la compagnie « CENTRE DE DÉCORATION BELOEILL LTEE », constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 novembre 1972 et ayant son siège social dans la ville de Beloeil a établi son bureau au numéro 224 Laurier.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Beloeil.ce 6e jour de novembre 1973.Le secrétaire.54756-0 Marthe Blanchette.BELOEIL DECORATIVE CENTER LTD.Notice is hereby given that the \"BELOEIL DECORATIVE CENTER LTD.\", incorporated by letters patent on the 9th day of November 1972, and having its head office in the City of Beloeil, has established its its office at No.224 Laurier.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Beloeil.this 6th day of November 1973.Marthe Blanchette, 54756-0 Secretary.BOURASSA NEON INC.Avis est donné que la compagnie « BOURASSA NEON INC.» ayant son siège social dans la ville dc Trois-Rivières, a établi son bureau au 1820.rue Bré-beuf.Trois-Rivières, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Les procureurs dc la compagnie, Chartier, Ménard & Gourueau.avocats.54758-0 70-64 BOURASSA NEON INC.Notice is given that \"BOURASSA NEON INC.\" having its head office in the City of Trois-Rivières has established its office at 1820 Brébeuf Street, Trois-Rivières, Québec.From the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as its head office.Chartier, Menard & Gourdeau, Lawyers, Attorneys for the company.54758 70-64 CORDONNERIE DE COW VNSVILLE INC.La compagnie « CORDONNERIE DE COWANSVILLE INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 721, rue Sud.Cowansville, au numéro 2476, rue Bourgogne, Chambly.Le secrétaire.Adrien Grosset.54765-o 723227 CORDONNERIE DE COWANSVILLE INC.Notice is given that \"CORDONNERIE DE COWANSVILLE INC.\" has transferred its head office from 721 South Street, Cowansville.to 2476 Bourgogne Street, Chambly.Adrien Grosset, Secretary.54765 723227 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, Si novembre 1973, 105' année, n\" 47 6995 BETON VIBRE LIMITEE La compagnie « BETON VIBRE LIMITEE » donne avis qu'elle a changé son siège social de Trois-Rivières, à Saint-Pierre-les-Becquets.Le secrétaire, Michel Paris.54757-0 13411-60 BETON VIBRE LIMITEE Notice is given that \"BETON VIBRE LIMITEE\" has transferred its head office from Trois-Rivières to St.Pierre-les-Becquets.Michel Paris, Secretary.54757 13411-60 BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS LTEE.THE FOUR SEASONS SHOP LTD.Avis est donné par les présentes que la compagnie « BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS LTEE \u2014 THE FOUR SEASONS SHOP LTD.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 15 février 1968, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, où son bureau était situé jusqu'à aujourd'hui, au numéro 615, boulevard Dorchester ouest, Montréal, a transféré son siège social à la suite 3411, Place Ville Marie, Montréal, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 19e jour d'octobre 1973.(Sceau) Le président, 54759 George L.A.Pinck.BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS LTEE.THE FOUR SEASONS SHOP LTD.Notice is hereby given that \"BOUTIQUE LES QUATRE SAISONS LTEE \u2014 THE FOUR SEASONS SHOP LTD.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent dated February 15th, 1968, and having its head office in the City and District of Montreal, where its office was situated up to today at Suite 840, 615 Dorchester Blvd.W.Montreal, has moved its head office to: Suite 3411, Place Ville Marie.Montreal, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 19th day of October, 1973, (Seal) George L.A.Pinck, 54759-0 President.SYSTEMES D'ORDINATEURS BUYDAL INC.BUYDAL COMPUTER SYSTEMS INC.Avis est donné que la compagnie « SYSTEMES D'ORDINATEURS BUYDAL INC.\u2014BUYDAL COMPUTER SYSTEMS INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 25e jour de juillet 1973, et ayant son siège social dans la cité de Montréal, a établi son bureau au numéro 500 Place d'Armes.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Les procureurs de la compagnie, 54760-o Geofrfion & Prud'homme.SYSTEMES D'ORDINATEURS BUYDAL INC.BUYDAL COMPUTER SYSTEMS INC.Notice is hereby given that \"SYSTEMES D'ORDINATEURS BUYDAL INC.\u2014BUYDAL COMPUTER SYSTEMS INC.\", incorporated by letters patent on the 25th day of July, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at number 500 Place d'Armes.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Geoffrion & Prud'homme, 54760-q Attorneys for the Company.CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.Avis est par les présentes donné que « CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.», constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies (Québec), par lettres patentes datées du 8 juin 1973, a établi son siège social en la ville de Montréal, au numéro civique 1182, rue de Bleury.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Daté à Montréal, Québec, ce 12e jour de novembre 1973.Le secrétaire.54761-o Pierre Mercier.CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.Notice is hereby given that \"CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.\".incorporated under Part III of the Companies Act (Québec), by letters patent dated June 8.1973, has established its head office in the City of Montreal, at civic number 1182 de Bleury Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the corporation as being its head office.Dated at Montreal.Québec, this 12th dav of November, 1973.Pierre Mercier.54761-0 Secretary. 6096 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.17 CANMEX INVESTMENTS INC.Avis est donné que la compagnie « CANMEX INVESTMENTS INC.» constituée en vertu de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 28 novembre, 1964 et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, l'a transporté à 1420 Sherbrooke Ouest, Chambre 502, en les ville et district de Montréal, province dc Québec.A compter dc la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 10e jour de septembre, 1973.Le president, Alfredo Berexstein.54762-0 4808-64 CANMEX INVESTMENTS INC.Notice is hereby given that \"CANMEX INVESTMENTS INC.\" incorporated under the Companies Act by letters patent dated November 28, 1964, having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, has moved it to 1420 Sherbrooke Street West, Suite 502, in the City and District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 10th day of September, 1973.Alfredo Berexstein, President.54762-o 4808-64 CENTRE DE NUTRITION DE MONTREAL INC.Avis est donné que la compagnie « CENTRE DE NUTRITION DE MONTREAL INC.» constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 19 juillet 1968 et ayant son siège social dans la Ville de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 4850 Côte des Neiges, appartement 605, l'a transporté au numéro 11250 rue Hamon.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 15e jour d'octobre 1973.Le secrétaire, 54763-0 Jean-Viaxxey Oiellette.CENTRE DE NUTRITION DE MONTREAL INC.Notice is given that \"CENTRE DE NUTRITION DE MONTREAL INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent bearing date the 19th of July 1968, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated until the present day at 4850 Côte des Neiges, Apartment 605, has transferred same to 11250 Hamon Street.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Montreal, this 15th day of October, 1973.Jeak-Vianney Ouellette, 54763 Secretary.CLAUDIA ORIGINAL LEATHER INC.LES CUIRS ORIGINAUX CLAUDIA INC.Avis est donné que la compagnie « CLAUDIA ORIGINAL LEATHER INC.\u2014 LES CUIRS ORIGINAUX CLAUDIA INC.a établi son siège social au numéro 1070 Bleury, Montréal, Province de Québec.Fait à Montréal, ce 1er octobre.1973.(Sceau) Président, 54764-0 Gérard Vidal.CLAUDIA ORIGINAL LEATHER INC.LES CUIRS ORIGINAUX CLAUDIA INC.Notice is given that the companv \"CLAUDIA ORIGINAL LEATHER INC.\u2014 LES CUIRS ORIGINAUX CLAUDIA INC.\" has established its head office at 1070 Blcury.Montreal, Province of Québec.Dated at Montreal on this 1st day of October.1973.(Seal) Gérard Vidal, 54764-0 President.EQUIPEMENT PIEDMONT LTEE PIEDMONT EQUIPMENT LTD.Avis est donné que la compagnie «EQUIPEMENT PIEDMONT LTEE » \u2014 « PIEDMONT EQUIPMENT LTD.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 28 décembre 1971 et ayant son siège social A Boucherville, Que., a établi son bureau au numéro 20, du boulevard Mortagne.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Boucherville, Que., le 2 octobre 1973.Le président, '/.J.Ciiagnon.54768-0 717276 EQUIPEMENT PIEDMONT LTEE PIEDMONT EQUIPMENT LTD.Notice is given that \"EQUIPEMENT PIEDMONT LTEE\" \u2014 PIEDMONT EQUIPMENT LTD.\", incorporated by letters patent dated December 28, 1971, and having its head office in Boucherville, P.Q., has established its office at number 20, Mortagne Boulevard.From the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Boucherville, P.Q., on October 2, 1973.Z.J.ClIAGNOX, President.54768-o 717276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2A novembre 1973, 105' année, n° 17 6997 DISTRIBUTEURS CONCORDE INC.Avis est donné que la compagnie « DISTRIBUTEURS CONCORDE INC.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 février 1973 et ayant son siège social à ville Saint-Laurent où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 335 rue Benjamin Hudon, l'a trasnporté au numéro 358 Boulevard Lebeau, Ville de Saint-Laurent.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 21e jour de mai 1973.(Sceau) Le président, 54767-0 Raymond Normandin.DISTRIBUTEURS CONCORDE INC.Notice is herebv given that the company \"DISTRIBUTEURS CONCORDE INC.\" incorporated by letters patent, on the 2nd day of February 1973, and having its head office in the City of Saint-Laurent, where its office was situated up to to-day, at 335 Benjamin Hudon street, has moved it to 358 Lebeau Blvd., City of Saint-Laurent.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 21st day of May 1973.(Seal) Raymond Normandin, 54767-0 President.LA FERME BEGIN LTEE Avis est donné que « LA FERME BEGIN LTEE » constituée en corporation en vertu de lettres patentes émises le 31 octobre 1963, et ayant son siège social dans la ville de Trois-Rivières où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 4425, rue Chamberland, l'a transporté à 1689, rue dc l'Eglise.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 17e jour d'août 1973.Le secrétaire, Marc Régnier.54769-0 4000-63 LA FERME BEGIN LTEE Notice is given that \"LA FERME BEGIN LTEE\", incorporated by letters patent dated October 31, 1963, and having its head office in the City of Trois-Rivières where its office was located until the present day at 4425 Chamberland Street, has transferred said office to 1689 de l'Eglise Street.From the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as its head office.Dated at Montreal, this 17th day of August, 1973.Marc Régnier, Secretary.54769 4000-63 THE FOUR SEASONS SPORTHOUSE INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « THE FOUR SEASONS SPORTHOUSE INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 10 novembre 1964, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, où son bureau était situé jusqu'à aujourd'hui au numéro 615, boulevard Dorchester ouest, suite 840, Montréal, a transféré son siège social à la suite 3411, Place Ville Marie, Montréal, Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 19e jour d'octobre 1973.Le président, 54770 George L.A.Pinck.THE FOUR SEASONS SPORTHOUSE INC.Notice is hereby given that \"THE FOUR SEASONS SPORTHOUSE INC.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent dated November 10th, 1964, and having its head office in the City and District of Montreal, where its office was situated up to today at Suite 840, 615 Dorchester Blvd.W., Montreal, has moved its head office to: Suite 3411, Place Ville Marie, Montreal, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 19th day of October, 1973.George L.A.Pinck, 54770-q President.GOYETTE TRANSPORT LIMITEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « GOYETTE TRANSPORT LIMITEE » a transporté son siège social du 920 rue Centrale à St-Joseph-de-St-Hyacinthe où il était situé auparavant pour l'établir au 900 rue Lajoie, à St-Joseph de St-Hyacinthe, district de St-Hyacinthe.Le secrétaire, (Sceau) Robert Goyette.54773-0 12685-55 GOYETTE TRANSPORT LIMITEE Notice is hereby given that \"GOYETTE TRANSPORT LIMITEE\" has transferred its head office from 920 Centrale Street, in St.Joseph-de-St.Hyacinthe, where it was formerly located, to 900 Lajoie Street, in St.Joseph-de-St.Hyacinthe, District of St.Hyacinthe.Robert Goyette, (Seal) Secretary.54773 12685-55 699s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 34, 1978, Vol.105, No.47 DELECTRIC INC.La compagnie « DELECTRIC INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 7717, rue Georges, LaSalle, au numéro 6615, avenue du Parc, Montréal.Le secrétaire-trésorier, Leopold Cusack.54766-0 5047-70 DELECTRIC INC.Notice is given that \"DELECTRIC INC.\" has trasferred its head office from 7717 Georges Street, LaSalle, to 6615 Park Avenue, Montreal.Leopold O.'sack, Secretary-Treasurer.54766 5047-70 ROLAND GAGNON & FILS INC.Avis est donné que la compagnie « ROLAND GAGNON & FILS INC.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 27 mars 1973 a son siège social dans le district de Montréal au 118 rue Leduc, à Cho-medey, Ville de Laval.La secrétaire, 54771-0 Mme Thérèse Gagnon.ROLAND GAGNON & FILS INC.Notice is given that \"ROLAND GAGNON & FILS INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent issued on March, 27th 1973, has its head office in the District of Montreal, 118 Leduc Street at Chomedey, City of Laval.Mrs.Thérèse Gagnon, 54771-0 Secretary.GESTION APEQ INC.La compagnie « GESTION APEQ INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal, au numéro 6120, rue Renoir, Montréal-Nord.La secrétaire, Yolande Roch Doganieri.54772-q 725668 GESTION APEQ INC.Notice is given that \"GESTION APEQ INC.\" has transferred its head office from Montreal, to 6120 Renoir Street, Montreal-North.Yolande Roch Doganieri, Secretary.54772 725668 LES IMMEUBLES DU VIEUX FORT LTEE Avis est donné que la compagnie « LES IMMEUBLES DU VIEUX FORT LTEE,» constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 18 mars 1965 et ayant son siège social en la Ville de Lévis où elle avait son bureau situé jusqu'à aujourd'hui, au numéro 45 Ouest, Route Trans-Canada, l'a transporté au numéro 108, Côte du Passage.À compter du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Lévis, ce 8ièmc jour de novembre 1973.Le secrétaire, 54774-0 Jacques Augeh.LES IMMEUBLES DU VIEUX FORT LTEE Notice is given that \"LES IMMEUBLES DU VIEUX FORT LTEE\", incorporated by letters patent issued on March 18, 1965 and having its head office in the City of Levis, where its office was situated up to the present day, at 45 Trans-Canada Highway, has transferred same to 108 Côte du Passage.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Levis, this 8th day of November, 1973.Jacques Auger, notary, 54774 Secretary.IMPEX CO.LIMITEE Avis est donné qu' « IMPEX CO.LIMITEE » constituée en corporation par lettres patentes en date du lie jour d'août 1967.et ayant son siège social dans le district dc Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui à 1010, Côte Beaver Hall, Suite 804, l'a transporté à 1255 Carré Philippe, Montréal, district de Montréal.A compter dc la date du présent avis ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 1 le jour d'octobre 1973.Le président, Amedeo Gatti.54775-0 3-444-67 IMPEX CO.LIMITEE Notice is hereby given that \"IMPEX CO.LIMITEE\" incorporated by Letters Patent on the 11th day of August, 1967, and having its head office in the district of Montreal where its office was situated up to today, at 1010, Côte Beaver Hall.Suite 804, has moved it to 1255 Philippe Square.Montreal, district of Montreal.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this Uth day of October 1973.Amedeo Gatti, President.54775-0 3344-67 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 47 6999 IMPORTATIONS MASCOUCHE LTEE La compagnie « IMPORTATIONS MASCOUCHE LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3730, boulevard Métropolitain est, Bureau 405, Montréal, au numéro 2846, Route 18, Mascouche.Le secrétaire, M.Jacques Bouchard.54776-0 733037 INNOCAN INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS INNOCAN LTEE Avis est donné que la compagnie « INNOCAN INVESTMENTS LTD.\u2014LES PLACEMENTS INNOCAN LTEE » constituée en corporation en vertu de la première partie de la loi des compagnies en date du 27e jour d'avril, son bureau situé jusqu'au 27e jour de septembre, 1973, au 22e étage, 630 ouest, boulevard Dorchester Montréal, l'a transporté au 10e étage, 2055 rue.Peel.À compter du 27e jour de septembre, 1973 ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Daté à Montréal, Québec le 22e jour d'octobre 1973.54777-0 Le président, Ronald Meade.73-1892 INTERCITY FOOD SERVICES INC.LES SERVICES ALIMENTAIRES INTERCITE INC.La compagnie « INTERCITY FOOD SERVICES INC.\u2014 LES SERVICES ALIMENTAIRES INTERCITE INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social de Mont-Royal au numéro 1500.avenue Atwater, Montréal 216.Le secrétaire.James N.Doyle.54778 2612-67 JASHKAMO CLEANERS INC.NETTOYEURS JASHKAMO INC.La compagnie « JASHKAMO CLEANERS INC.\u2014 NETTOYEURS JASHKAMO INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 5680.Chemin de la Côtc-des-Neiges, Montréal, au numéro 597, Côte Vertu, Saint-Laurent.Le président, Sukhjit Kaur Dhariwal.54779 736270 LAUZON DRIVE YOl'RSELF INC.La compagnie « LAUZON DRIVE YOURSELF INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social de Montréal, au numéro 7401, boulevard Newman, I.asalle.Le secrétaire, Pierre Hogue.54781 10146-54 IMPORTATIONS MASCOUCHE LTEE Notice is given that \"IMPORTATIONS MASCOUCHE LTEE\" has transferred its head office from 3730 Métropolitain Boulevard East, Office 405, Montreal, to 2846 Highway 18, Mascouche.Mr.Jacques Bouchard, Secretary.54776 733037 INNOCAN INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS INNOCAN LTEE Notice is hereby given that \"INNOCAN INVESTMENTS LTD.\u2014 LES PLACEMENTS INNOCAN LTEE\" incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent dated April 27, 1973, and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec where its head office was situated up to September 20, 1973 at 22nd Floor, 630 Dorchester Boulevard has moved it to the 10th Floor, 2055 Peel Street.From and after September 20, 1973 the said office shall be considered by the Company as being the Head Office of the Company.Dated at Montreal, Québec this 22nd day of October 1973.Ronald Meade, President.54777-0 73-1892 INTERCITY FOOD SERVICES INC.LES SERVICES ALIMENTAIRES INTERCITE INC.Notice is given that \"INTERCITY FOOD SERVICES INC.\u2014 LES SERVICES ALIMENTAIRES INTERCITE INC.\" has transferred its head office from Mount-Roval to 1500 Atwater Avenue, Montreal 216.James N.Doyle, Secretary.54778-0 2612-67 JASHKAMO CLEANERS INC.NETTOYEURS JASHKAMO INC.Notice is given that \"JASHKAMO CLEANERS INC.\u2014 NETTOYEURS JASHKAMO INC.\" has transferred its head office from 5680 Côte-des-Neiges Road, Montreal, to 597 Côte Vertu, Saint-Laurent.Sukhjit Kaur Dhariwal, President.54779-0 736270 LAUZON DRIVE YOURSELF INC.Notice is given that \"LAUZON DRIVE YOURSELF INC.\" has transferred its head office from Montreal, to 7401 Newman Boulevard, Lasalle.54781-o Pierre Hogue, Secretary.10146-54 7000 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November SA, 1973, Vol.105, No.A7 LABORATOIRE PENTAGONE LTEE PENTAGONE LABORATORY LTD.Avis est par les présentes donné que « LABORATOIRE PENTAGONE LTEE \u2014 PENTAGONE LABORATORY LTD.», ayant son siège social en la ville de Montréal, l'a établi au 3737 est, boulevard Métropolitain.Donné à Montréal, ce 30e jour d'octobre 1973.Le secrétaire, Claude Lachapellb.54780-o 13542-60 LABORATOIRE PENTAGONE LTEE PENTAGONE LABORATORY LTD.Notice is herebv given that \"LABORATOIRE PENTAGONE LTEE \u2014 PENTAGONE LABORATORY LTD.\", having its head office in the City of Montreal, has established said office at 3737 Metropolitan Boulevard East.Given in Montreal, this 30th day of October, 1973.Claude Lachapelle, Secretary.54780 13542-60 LEIGH INVESTMENTS (MONTREAL) LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « LEIGH INVESTMENTS (MONTREAL) LTD.».constituée en corporation par lettres patentes en date du 26e jour de juillet 1963, et ayant son siège social en la ville de Montréal, où elle avait son bureau situé au 1155.boulevard Dorchester ouest, l'a transféré au numéro 1, Place Ville Marie, suite 3635, en la ville dc Montréal, district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 9e jour d'octobre 1973.Le secrétaire.Murray Stewart Webb.54782 3243-63 MAISON JEROME INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie «MAISON JEROME INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, a transféré son siège social du numéro 6846, rue St-Hubert, en les ville et district de Montréal, Québec, au numéro 5350, rue Henri-Julien, en la ville de Montréal, province de Québec, ledit changement entre en vigueur immédiatement.Fait à Montréal, le 16 avril 1973.La secrétaire.Mme Réjane Jérôme.54783 10040-62 LEIGH INVESTMENTS (MONTREAL) LTD.Notice is herebv given that \"LEIGH INVESTMENTS (MONTREAL) LTD.\", incorporated by letters patent on the 26th day of July, 1963, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at 1155 Dorchester Boulevard West, has moved it to 1 Place Ville Marie, Suite 3635, in the City of Montreal.District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 9th day of October, 1973.Murray Stewart Webb, Secretary.54782-0 3243-63 MAISON JEROME INC.Notice is hereby given that \"MAISON JEROME INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act has moved its head office from 6846 St.Hubert Street, in the City ami District of Montreal, Québec, to 5350 Henri-.Iuiien Street in the City of Montreal, Province of Québec, effective immediately.Dated at Montreal.April 16th.1973.Mus.Réjane Jérôme.Secretary.54783-0 10040-62 LA SOCIETE CANADIENNE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE INC.Avis est par les présentes que la compagnie « LA SOCIETE CANADIENNE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE INC.» constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la Ville dc Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 6915, 30e Avenue Rosemont, app.2, l'a transporté au 500 Place d'Armes suite 1610, Montréal H2Y 2W2.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 22e jour d'octobre 1973.Le secrétaire-général.54789-0 C.Germain Beauregard, m.d.LA SOCIETE CANADIENNE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE INC.Notice is herebv given that \"LA SOCIETE CANADIENNE FRANÇAISE DE RADIOLOGIE INC.\", incorporated under Part III of the Companies Act and having its head office in the City of Montreal where its office was situated up to to-day at 6915, 30e Avenue, Rosemont, apt.2, has moved it to 500 Place d'Armes suite 1610, Montreal H2Y 2W2.From the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.Given at Montreal, this 22nd day of October.1973.C.Gkr.main Beauregard, m.d., 54789-o General Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SI novembre 1973, 105' année, u° 17 7001 LES MAISONS FAMILIALES D'YOUVILLE INT.Avis est par les présentes donné que la compagnie «LES MAISONS FAMILIALES D'YOU VILLE INC.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la troisième partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 29 avril 1972, et ayant son siège social à Montréal situé jusqu'à présent au 1828 est, boulevard Gouin, Montréal, l'a transféré au 5633 est, de la rue Sherbrooke, Montréal.Donné à Montréal, ce 20e jour d'août 1973.Le président, 54784-0 Rolland Bastien, notaire.LES MAISONS FAMILIALES D'YOUVILLE INC.Notice is hereby given that \"LES MAISONS FAMILIALES D'YOUVILLE INC.\", incorporated under the provisions of Part III of the Companies Act, by letters patent dated April 29, 1972, and having its head office in Montreal, located until the present day at 1828 Gouin Boulevard East, Montreal, has transferred said office to 5633 Sherbrooke Street East, Montreal.Given at Montreal, this 20th day of August, 1973.Rolland Bastien, notary, 54784 President.PHILMAR COOLING INC.REFRIGERATION PHILMAR INC.Avis est donné que la compagnie « PHILMAR COOLING INC.\u2014 REFRIGERATION PHILMAR INC.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 15e jour de juin 1973, et ayant son siège social dans la Ville de St-Laurent, a établi son bureau au numéro 520 rue Hodge.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social./-e.v procureurs de la compagnie, 54785-0 Geoffrion & Prud'homme.PHILMAR COOLING INC.REFRIGERATION PHILMAR INC.Notice is herebv given that \"PHILMAR COOLING INC.\u2014 REFRIGERATION PHILMAR INC.\" incorporated by letters patent on the 15th day of June, 1973, and having its head office in Ville St-Laurent, has established its office at number 520 Hodge Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Geoffrion & Prud'homme, 54785-0 Attorneys for the Company.QUEBEC SCHOOL PHOTOGRAPHY SERVICES INC.LES SERVICES DE PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE DU QUEBEC INC.La compagnie «QUEBEC SCHOOL PHOTOGRAPHY SERVICES INC.\u2014 LES SERVICES DE PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE DU QUEBEC INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 615, boulevard Dorchester ouest, suite 1010, Montréal, au numéro 2366, 46e Avenue.Lachine.Le secrétaire.Colin Ghavenor, Fils.54787 73715S LA CORPORATION DU CONSEIL DES CITOYENS DU MONDE AU QUEBEC INC.Avis est par les présentes donné que l'association «LA CORPORATION DU CONSEIL DES CITOYENS DU MONDE AU QUEBEC INC.» constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la partie III de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 21 septembre 1973, et ayant son siège social en la Ville de Montréal, a établi son bureau principal à 18 Fundy, Place Bona-venture.Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la corporation comme étant son siège social.Montréal, ce 9e jour de novembre 1973.(Sceau) Le président, 54831-0 Lt.Col.Sarto Marchand.QUEBEC SCHOOL PHOTOGRAPHY SERVICES INC.LES SERVICES DE PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE DU QUEBEC INC.Notice is given that \"QUEBEC SCHOOL PHOTOGRAPHY SERVICES INC.\u2014 LES SERVICES DE PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE DU QUEBEC INC.\" has transferred its head office from 615 Dorchester Boulevard West.Suite 1010, Montreal, to 2366, 46th Avenue, Lachine.Colin Gravenor, Jr., Secretary.54787-0 737158 LA CORPORATION DU CONSEIL DES CITOYENS DU MONDE AU QUEBEC INC.Notice is herebv given that the Association \"LA CORPORATION DU CONSEIL DES CITOYENS DU MONDE AU QUEBEC INC.\" incorporated in the Province of Québec, under Part III of the Companies Act.by letters patent bearing the date of September the 21st.1973.and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 18 Fundy, Place Bonaventure, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Association as being its head office.Montreal, this 9th day of November, 1973.(Seal) Lt.Col.Sarto Marchand, 54831-0 President. 7002 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November H, 1973, Vol.105, No.17 NORDORE MINING CO.LTD.Avis est donné que la compagnie « NORDORE MINING CO.LTD.» constituée en corporation par lettres patentes en date du 9 février 1971 et ayant son siège social dans la ville de Val-d'Or où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au 141 boulevard Perrault, l'a transporté au 153 boulevard Perrault.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Val-d'Or, ce 24e jour d'octobre 1973.Le president, Rayxerd B.Carsox.54786-0 642-1971 LA ROBE DU QUEBEC (1973) INC.Prenez avis que la compagnie « LA ROBE DU QUEBEC (1973) INC.», incorporée en vertu de la Loi des compagnies, le 27 septembre 1973, a établi son siège social à 211, St-Joseph, L'Assomption, province de Québec.Montréal, ce 2e jour de novembre 1973.Le président, 54788-0 Georges Cadorbt.NORDORE MINING CO.LTD.Notice is hereby given that the \"NORDORE MINING CO.LTD.\" company incorporated by letters patent on the 9th day of February 1971 and having its head office in the city of Val-d'Or where its office was situated up to today at 141 Perrault Boulevard has moved it to 153 Perrault Boulevard.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Val-d'Or, this 24th day of October 1973.Raynerd B.Carson, President.54786-0 642-1971 LA ROBE DU QUEBEC (1973) INC.Notice is hereby given that \"LA ROBE DU QUEBEC (1973) INC.\"\", duly constituted under the Companies Act, on September 27, 1973, has established its head office at 211 St.Joseph, L'Assomption.Signed at Montreal, this 2nd day of November, 1973.Georges Cadoret, 54788-0 President.STANGARD INC.La compagnie « STANGARD INC.», donne avis qu'elle a changé son siège social de Montréal, au numéro 6120.rue Renoir, Montréal-Nord.La secrétaire, Yolande Roch Doganieri.54790-o 726544 TAXI VILLANI LTEE Avis est donné que la compagnie « TAXI VTLLANI LTEE » constituée en corporation par lettres patentes datées du 3 août 1973 a son bureau chef au numéro 213 rue Mont-Vernon, à Ville St-Pierre, district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau chef.Donné à Cité Lasalle, ce 6c jour d'août 1973.Le président, 54791-0 Arcaxgei.o Tiscia.STANGARD INC.Notice is given that \"STANGARD INC.\" has transferred its head office from Montreal, to 6120 Renoir Street, Montreal-North.Yolande Roch Doganieri, Secretary.54790 726544 TAXI VILLANI LTEE Notice is given that \"TAXI VILLANI LTEE\", incorporated by letters patent dated August 3, 1973, has established its head office at 213 Mont-Vernon Street, in Town of St.Pierre, District of Montreal.From the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as its head office.Given in City of Lasalle, this 6th day of August, 1973.Arcangelo Tiscia, 54791 President.GAETAN FORTIN INC.Avis est donné que la compagnie « GAETAN FORTIN INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 4 juin 1973 et enregistrées le 6 juillet 1973, et ayant son siège social dans la ville d'Ibervillc a établi son bureau au numéro 275, âième Avenue.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Iberville, ce 17e jour d'octobre 1973.54834-0 Gaétan Fortin.GAETAN FORTIN INC.Notice is given that \"GAETAN FORTIN INC.\" incorporated by letters patent dated June 4, 1973 and registered on July 6, 1973, having its head office in the Town of Iberville has established said office at 275, 5th Avenue.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated in Iberville, this 17th day of October.1973.54834 Gaétan Fortin. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2k novembre 1973, 105' année, n\" 17 7003 MAURICE DESY & FILS INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « MAURICE DESY & FILS INC.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies (Québec) par lettres patentes émises le 2 août 1973 a établi son bureau principal au 389, rue du Roi, à Asbestos, district de Richmond, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Warwick, ce 1er jour de novembre 1973.Le président, 54832-0 Maurice Dêsy.L'EVEIL MUSICAL D'ANJOU Avis est donné que la compagnie « L'EVEIL MUSICAL D'ANJOU », constituée en corporation au Québec par lettres patentes en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies en date du 3e jour de mai 1973, et ayant son siège social à Ville d'Anjou a établi son bureau au numéro 7931 de la rue Wilfrid-Peljetier.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Ville d'Anjou, ce 13e jour de novembre 1973.La secrétaire, 54833-0 Claire Faust Lambert.RESTAURANTS & MOTELS INTER-CITE INC.La compagnie « RESTAURANTS & MOTELS INTER-CITE INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 3287, rue Ackin, Saint-Laurent, à Sortie 125, Route Trans-Canada, Sainte-Eulalie.Le président, Andre Verdier.54836-0 2483-66 Député élu Bureau du Président général des élections Québec, le 20 novembre 1973.Je donne par les présentes avis que le collège électoral suivant a élu député, le candidat ci-après désigné, pour le représenter dans la nouvelle Assemblée nationale du Québec: Sainte-Marie Monsieur Jean-Claude Malépart, administrateur-animateur, 2265, rue Hogan, Montréal.\u2014 Parti libéral du Québec.Le suppléant du président général des élections, 54860-o Eddv Giguère, avocat.MAURICE DESY & FILS INC.Notice is hereby given that \"MAURICE DESY & FILS INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act (Québec) by letters patent dated August 2nd, 1973 has established its head office at number 389, Du Roi Street, Asbestos, district of Richmond, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the company as being its head office.Given at Warwick, this 1st day of November, 1973.Maurice Désy, 54832-0 President.L'EVEIL MUSICAL D'ANJOU Notice is hereby given that the \"L'EVEIL MUSICAL D'ANJOU\", company incorporated by letters patent under Part III of the Companies Act, on the 3rd day of May, 1973, and having its head office in Ville d'Anjou, has established its office at No.7931 Wilfrid-Pelletier.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Ville d'Anjou, this 13th day of November, 1973.Claire Faust Lambert, 54833-0 Secretary.RESTAURANTS & MOTELS INTER-CITE INC.Notice is given that \"RESTAURANTS & MOTELS INTER-CITE INC.\" has transferred its head office from 3287 Ackin Street, St.Laurent, to Exit 125, Trans-Canada Highway.Ste.Eulalie.André Verdier, President.54836 2483-66 Member Elected Office of the Chief Returning-Officer Québec, November 20, 1973.I hereby give notice that the candidate herein after mentioned have been returned as deputy to represent the following electoral division in the new National Assembly of Québec: Sainte-Marie Mr.Jean-Claude Malépart, Director-Group leader, 2265, Hogan Street, Montreal.\u2014 Québec Liberal Party.The Acting Chief Returning-Officer, 54860-o Eddy Giguere, Advocate. 7001 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November SA, 1973, Vol 105, No.A7_ Charte \u2014 Charter \u2014 demandes d'abandon de Applications for Surrender of LES PUBLICATIONS FRANÇAISES A.A.INC.A.A.FRENCH PUBLICATIONS INC.Prenez avis que la compagnie « LES PUBLICATIONS FRANÇAISES A.A.INC.\u2014 A.A.FRENCH PUBLICATIONS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province la permission d'abandonner sa charte.Granby, ce 29 octobre 1973.Les procureurs de la compagnie, 54722-0 Marquis, Jutras & Guertik.LES PUBLICATIONS FRANÇAISES A.A.INC.A.A.FRENCH PUBLICATIONS INC.Notice is given that \"LES PUBLICATIONS FRANÇAISES A.A.INC.\u2014A.A.FRENCH PUBLICATIONS INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Granby, October 29th 1973.Marquis, Jutras & Guertin, 54722-0 Attorneys for the company L'AIDE A L'EDUCATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GRANBY INC.Avis est donné que la compagnie « L'AIDE A L'EDUCATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GRANBY INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la Ville de Granby, P.Q.s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Granby, P.Q., ce 5e jour de novembre 1973.Le notaire, 54723-0 Daniel Southière.L'AIDE A L'EDUCATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GRANBY INC.Notice is herebv given that \"L'AIDE A L'EDUCATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GRANBY INC.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the City of Granby, Que., will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Granbv, Que., this 5th day of November, 1973.Daniel Southière, 54723-0 Notary.LA CIE DE CONSTRUCTION ST-GEORGES DE SHERBROOKE INC.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « LA CIE DE CONSTRUCTION ST-GEORGES DE SHERBROOKE INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Sherbrooke, Que.s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Ix>i des compagnies.Daté ce 7e jour de novembre 1973.Le secrétaire, 54726-0 Victor Newton.LA CIE DE CONSTRUCTION ST-GEORGES DE SHERBROOKE INC.Notice is herebv given that \"LA CIE DE CONSTRUCTION ST-GEORGES DE SHERBROOKE INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at Sherbrooke, Que., will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated this 7th day of November 1973.Victor Newton, 54726-0 Secretary.DOMINION SYNTHETICS LTD.Avis est donné par les présentes que la compagnie « DOMINION SYNTHETICS LIMITED », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 7e jour de novembre 1973.La secrétaire, 54728 Mme Lorraine Finlay.DOMINION SYNTHETICS LTD.Notice is hereby given that \"DOMINION SYNTHETIC'S LTD.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Finanical Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 7th day of November, 1973.Mrs.Lorraine Finlay, 54728-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 197.% 105' année, u° 47 7005 ALOUETTE AUTOMOBILE INC.Prenez avis que la compagnie « ALOUETTE AUTOMOBILE INC.», ayant son siège social à Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 31 octobre 1973.Le procureur de la compagnie, 54724-0 Me Bern ah d Larochelle, notaire.BEGIN SLATE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « BEGIN SLATE INC.», incorporée en date du 3 février 1967 sous l'empire de la Loi des compagnies, première partie, et ayant son siège social à Montréal présentera incessamment auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province dc Québec une requête pour abandon de charte suivant les dispositions dc la Loi des compagnies.Montréal, 20 octobre 1973.(Sceau) La secrétaire.54725-0 Lise Déziel Bégin.ALOUETTE AUTOMOBILE INC.Notice is given that \"ALOUETTE AUTOMOBILE INC.\", having its head office in Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, October 31, 1973.Me Bernard Larochelle, notary, 54724 Attorney for the company.BEGIN SLATE INC.Notice is hereby given that \"BEGIN SLATE INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act on February 3.1967, and having its head office in Montreal, will apply forthwith to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter in compliance with the provisions of the Companies Act.Montreal, October 20, 1973.(Seal) Lise Déziel Begin, 54725 Secretary.LES ENTREPRISES DECORATEX INC.DECORATEX ENTERPRISES INC.Avis est donné par les présentes que la compagnies « LES ENTREPRISES DECORATEX INC.\u2014 DECORATEX ENTERPRISES INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville dc Montréal, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 7 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.Marks, Shapiro, Hoffman, 54727 Green & Beinhakeh.LES ENTREPRISES DECORATEX INC.DECORATEX ENTERPRISES INC.Notice is herebv given that \"LES ENTREPRISES DECORATEX INC.\u2014 DECORATEX ENTERPRISES INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act, having its head office in the City of Montreal, will apply for leave to surrender its charter.Montreal, November 7, 1973.Marks, Shapiro, Hoffman, Green & Beinhakeh, 54727-0 Attorneys for the Company.INTERBANCORP (MTL) LTD.Avis est par les présentes donné que \" INTERBANCORP (MTL) LTD.» demandera au ministre dc la consommation et des corporations la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 31 cotobre 1973.Les procureurs de la compagnie.Guy.Vaillancouht, Bertrand, 54731-o Bourgeois & Laurent.INTERBANCORP (MTL) LTD.Notice is hereby given that \"INTERBANCORP (MTL) LTD.\" will apply to the Minister of Consumer and Corporate Affairs for leave to surrender its charter.Montreal, October 31.1973.Guy, Vaillancouht.Bertrand.Bourgeois & Laurent, 54731-0 Attorneys for the Company.KEAYS CONSTRUCTION INC.Avis est donné que « KEAYS CONSTRUCTION INC.», constituée le 1er août 1949 .demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 24 octobre 1973.Les procureurs de la compagnies.Létourneau, Stein.Marseille, 54733-q Delisle & Larue.KEAYS CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"KEAYS CONSTRUCTION INC.\", incorporated on August 1st, 1949, will apply to the minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, October 24, 1973.Létourneau, Stein, Marseille, Delisle & Larue, 54733-0 Attorneys for the companies. 7006 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2A, 1973, Vol.105, No.L7 G S INVESTMENTS LTD Avis est donné par les présentes que la compagnie « G S INVESTMENTS LTD.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, province dc Québec, demandera la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 8 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.Marks Shapiro, Hoffman.54729 Green & Beinhakeh.G S INVESTMENTS LTD Notice is hereby given that \"G S INVESTMENTS LTD.\", incorporated under Part I of the Companies Act, having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply for leave to surrender its charter.Montreal, November 8, 1973.Marks, Shapiro, Hoffman, Green & Beinhaker.54729-q Attorneys for the Company.HATCH & COMPANY LIMITED Prenez avis que la compagnie « HATCH & COMPANY LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Québec, ce 23e jour d'octobre, 1973.Les procureurs de la compagnie, Létourneau, Stein.54730-o Marseille, et al.HATCH & COMPANY LIMITED Notice is given that \"HATCH & COMPANY LIMITED\" will apply to the Minister of Financial institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Dated at Québec, this 23rd day of October, 1973.Létourneau, Stein, Marseille, et al, 54730 Attorneys for the company.KAMIS INDUSTRIES INC.Avis est donné que « KAMIS INDUSTRIES INC.» compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Donné à Québec, ce 12 novembre.1973.Les procureurs de la compagnie.St-Hilaire.De Blois.54732-0 & Associés.KAMIS INDUSTRIES INC.Notice is hereby given that \"KAMIS INDUSTRIES INC.\" incorporated under the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Québec, this 12th of November, 1973.St-Hilaire, De Blois.& Al, 54732-q Attorneys for the company.KUZIK CARWASH & SERVICE LTD Avis est, par les présentes, donné que « KUZIK CARWASH & SERVICE LTD.» ayant son bureau-chef à Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, à partir dc la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté à Montréal, ce 12e jour de novembre, 1973.Le procureur dc la requérante.54735-0 Alexander Biega, c.r.KUZIK CARWASH AND SERVICE LTD Notice is hereby given that \"KUZIK CARWASH AND SERVICE LTD.\" having its head office at Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 12th day of November, 1973.Alexander Biega, q.c, 54735-0 Attorney for the petitioner.MIJA CORPORATION Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « MIJA CORPORATION » donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Montréal.P.Q., ce 9c jour de novembre, 1973.Le secrétaire-trésorier.5474 l-o H.W.Tnowssi:.MIJA CORPORATION Under the provisions of the Companies Act, \"MIJA CORPORATION\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the Company, for cancellation of the charter and for the dissolution of the Company.Montreal, P.Q.this 9th day of November.1973.H.W.Trowsse, 54741-0 Secretary-Treasurer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SA novembre 1973, 105' année, n' 47 7007 J.E.KEAYS LTEE Avis est donné que « J.E.KEAYS LTEE », constituée le 1er août 1949 demandera, au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 24 octobre 1973.Les procureurs des compagnies, létourneau, stein, MaRSEII.EE, 54734-0 Delisle & Larue.J.E.KEAYS LTEE Notice is given that \"J.E.KEAYS LTEE\", incorporated on August 1st, 1949, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, October 24, 1973.létourneau, stein, marseille, Delisle & Larue, 54734-0 Attorneys for the companies.L & S STEINBERG HOLDINCS CO.Avis est donné que « L & S STEINBERG HOLDINGS CO.» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 9e jour de novembre, 1973.Les procureurs de la compagnie, Meyerovitch & Goldstein.1255 rue Université, Montréal 110.54737-o L & S STEINBERG HOLDINGS CO.Notice is hereby given that \"L & S STEINBERG HOLDINGS CO.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, November 9, 1973.Meyerovitch & Goldstein, Attorneys for the company.1255 University St., Montreal 110.54737-0 MARMERSTEIN LTD.Avis est par les présentes donné que « MARMERSTEIN LTD.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de l'Assomption, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 16e jour d'octobre, 1973.' Le secrétaire, 54740-O S.Tenenbaum.MARMERSTEIN LTD.Notice is hereby given that \"MARMERSTEIN LTD.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of l'Assomption will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 16th day of October, 1973.S.Tenenbaum, 54740-o Secretary.PAVAGE REGIONAL INC.REGIONAL PAVING INC.Avis est donné que la compagnie « PAVAGE REGIONAL INC.\u2014 REGIONAL PAVING INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Georges Arcouette, notaire.7155 Christophe-Colomb, Montréal 328.54743-0 PAVAGE REGIONAL INC.REGIONAL PAVING INC.Notice is given that \"PAVAGE REGIONAL INC.\u2014 REGIONAL PAVING INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Georges Arcouette, notary.Attorney for the company.7155 Christophe-Colomb, Montreal 328.54743 SEIGNIORY INVESTMENT CORP.Avis est par les présentes donné que la compagnie « SEIGNIORY INVESTMENT CORP.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce vingt-cinquième jour d'octobre, mil neuf cent soixante-treize.Le secrétaire, 54745 Sydney Weisbord.SEIGNIORY INVESTMENT CORP.Notice is hereby given that \"SEIGNIORY INVESTMENT CORP.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this twenty-fifth day of October nineteen hundred and seventy-three.Sydney Weisbord, 54745-0 Secretary. 7008 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 KUZIK ENTERPRISES INC.Avis est, par les présentes, donné que « KUZIK ENTERPRISES INC.» ayant son bureau-chef à Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner ses lettres patentes, à partir de la date qu'il lui plaira de déterminer.Daté à Montréal, ce 7e jour dc novembre, 1973.Le procureur de la requérante, Alexander Biega.Suite 525, 276, St.James St.West, Montréal 126, Canada.54736-o LEFEBVRE & PRUDHOMME INC.Prenez avis que la compagnie « LEFEBVRE & PRUDHOMME INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.fes procureurs de la compagnie, 54738-0 Martin & Blais.notaires.KUZIK ENTERPRISES INC.Notice is hereby given that \"KUZIK ENTERPRISES INC.\" having its head office at Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its letters patent, from and after the date which he will be pleased to determine.Dated at Montreal, this 7th day of November 1973.Alexander Biega, Attorney for the petitioner.Suite 525, 276 St.James St.West, Montreal 126, Canada.54736-o LEFEBVRE & PRUDHOMME INC.Notice is given that \"LEFEBVRE & PRUDHOMME INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Martin & Blais, notaries, 54738 Attorneys for the company.LA MAISON DES OPERATEURS INC.Prenez avis que la compagnie « LA MAISON DES OPERATEURS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 31 octobre 1973.Les procureurs de la compagnie, 54739-0 Décary, Jasmin, Rivest et Lalrix.LA MAISON DES OPERATEURS INC.Take notice that the company \"LA MAISON DES OPERATEURS INC.\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter.Montreal, October 31st, 1973.Décary, Jasmin, Rivest & Laurin, 54739-0 Attorneys for the company.4-C DISTRIBUTION INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « 4-C DISTRIBUTION INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Valcourt, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permis-mission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Valcourt, ce 26e jour d'octobre 1973.La secrétaire.Pierrette Arbl.54744-0 4513-68 TANYOR LTD.TANYOR LTEE Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies, « TANYOR LTD.\u2014 TANYOR LTEE » s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, que son annulation soit dirigée et qu'une date soit fixée à compter de laquelle la compagnie sera dissoute.Montréal.P.Q.ce 31c jour d'octobre 1973.(Sceau) Le secrétaire.54747-0 N.L.Henri.4-C DISTRIBUTION INC.Notice is hereby given that \"4-C DISTRIBUTION INC.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Valcourt, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Valcourt, this 26th day of October 1973.Pierrette Arel, Secretary.54744-0 4513-68 TANYOR LTD.TANYOR LTEE Under the provisions of the Companies Act.\"TANYOR LTD.\u2014 TANYOR LTEE\" hereby gives notice that it will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for acceptance of the surrender of its charter and to direct its cancellation and fix a date upon and from which it shall be dissolved.Montreal, P.Q.this 31st day of October.1973.(Seal) N.L.Henri.54747-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2i novembre 1973, 105' armée, n\" A7 7009 L'OUVERTURE LAURENTIENNE INC.Prenez avis que la compagnie « L'OUVERTURE LAURENTIENNE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 54742-0 Dion, Tremblay & Roy.L'OUVERTURE LAURENTIENNE INC.Notice is given that \"L'OUVERTURE LAURENTIENNE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dion, Tremblay & Roy, 54742 Attorneys for the company.SOGINVEST CANADA LTD.Prenez avis que la compagnie « SOGINVEST CANADA LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 54746-0 Michel Simard & associés.SOGINVEST CANADA LTD.Take notice that \"SOGINVEST CANADA LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Michel Simard & Associates, 54746-0 Attorneys for the Company.UNICORD ltd.Avis est par les présentes donné que la compagnie « UNICORD LTD.», corporation constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, ayant son siège social dans la ville de Montréal, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte conformément aux disppositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 24e jour d'octobre, 1973.Le secrétaire-trésorier, 54749-0 Pol Paskal.UNICORD LTD.Notice is hereby given that \"UNICORD LTD.\", a corporation constituted under Part I of the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the terms of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, October 24th, 1973.Pol Paskal, 54749-0 Secretary-Treasurer.CENTRE DE TRAITEMENT L'ESCALE INC.Prenez avis que la compagnie « CENTRE DE TRAITEMENT L'ESCALE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 54806-o Julien & Tremblay, avocats.CENTRE DE TRAITEMENT L'ESCALE INC.Notice is given that \"CENTRE DE TRAITEMENT L'ESCALE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Julien & Tremblay, Lawyers, 54806 Attorneys for the Company.LES IMMEUBLES FIGARO INC.La compagnie « LES IMMEUBLES FIGARO INC.» donne avis qu'elle demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.54807-o Lucien Roy, avocat.LES IMMEUBLES FIGARO INC.Notice is given that \"LES IMMEUBLES FIGARO INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.54807-o Lucien Roy, Lawyer.4492 SHERBROOKE STREET WEST (INC.) En vertu de la première partie de la Loi des compagnies.«4492 SHERBROOKE STREET WEST (INC.) » donne avis par les présentes, qu'elle demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, Québec, ce 15e jour de novembre 1973.Les procureurs de la compagnie, 54809-o Laidley, Howard, Lesace & associés.4192 SHERBROOKE STREET WEST (INC.) Under the Part I of the Companies Act \"4492 SHERBROOKE STREET WEST (INC.)\" hereby gives notice that it will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the company.Dated at Montreal, this 15th day of November 1973.Laidley.Howard, Lesage & Associates, 54809-o Attorneys for the company. 7010 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 THORPVILLE INVESTMENTS LIMITED Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « THORPVILLE INVESTMENTS LIMITED » donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution dc la compagnie.Montréal, P.Q., ce 1er jour de novembre, 1973.Le secrétaire-trésorier.54748-0 M.F.Seymour.THORPVILLE INVESTMENTS LIMITED Under the provisions of the Companies Act, \"THORPVILLE INVESTMENTS LIMITED\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the Company, for cancellation of the charter and for the dissolution of the Company.Montreal, P.Q., this 1st day of November, 1973.M.F.Seymour, 54748-0 Secretary-Treasurer.FERME THIBAUDEAU LIMITEE Prenez avis que la compagnie « FERME THIBAUDEAU LIMITEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Thurso, ce 9 novembre 1973.Le procureur de la compagnie.54808-o Gerald Robert, notaire.FERME THIBAUDEAU LIMITEE Notice is hereby given that the company \"FERME THIBAUDEAU LIMITEE\" will request the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives the permission to surrender its charter.Thurso, November 9, 1973.Gerald Robert, Notary, 54808-o Attorney for the company.ALMAR LTEE Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « ALMAR LTEE » constituée en corporation suivant les dispositions de la Loi des Compagnies, et ayant son siège social au 110-A rue dos Forges, Trois-Rivières, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour demander la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Trois-Rivières.ce 14 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.GlROUARD, BeAUMIER.54837-0 Richard & Roberge.ALMAR LTEE Notice is hereby given that \"ALMAR LTEE\" a corporation incorporated under the companies Act and having its head office at 110-A Des Forges street.Trois-Rivières, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter, under the provisions of the companies Act.Dated at Trois-Rivières, this 14th November 1973.GlROUARD, BEAUMIER, Richard & Roberge, 54837-0 Attorney for the company.J.COGAN INC.Avis est par les présentes donné que « J.COGAN INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir l'abandon de sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 1er jour île novembre 1973.Le président.54839-0 Jean Cogan.J.COGAN INC.Notice is hereby given that \"J.COGAN INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 1st day of November, 1973.Jean Cogan, 54839-0 President.HOPITAL GENERAL DE JOLIETTE Avis est par les présentes donné que la compagnie « HOPITAL GENERAL DE JOLIETTE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Joliette, le 30 octobre 1973.Le procureur de la compagnie.54842-0 André Rondeau, notaire.HOPITAL GENERAL DE JOLIETTE Notice is hereby given that the company \"HOPITAL GENERAL DE JOLLETTE\" shall request the Minister of Financial Institutions.Companies and Coope.ratives to grant the permission to surrender its charter Joliette, October 30, 1973.André Rondeau.Notary.54842-0 Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U novembre 1973, 105' année, n' 47 7011 JACQUES BOUESNARD LTD.Avis est donné que la compagnie « JACQUES BOUESNARD LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de sa province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 13e jour de novembre 1973.Les procureurs de la compagnie, Marc, Shapiro, Hoffman, 54805 Green & Beinhaker.JACQUES BOUESNARD LTD.Take notice that \"JACQUES BOUESNARD LTD.\", a Company incorporated under the Companies Act and having its head office at Montreal, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its Charter, under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 13th day of November 1973.Marks, Shapiro, Hoffman, Green & Beinhaker, 54805-o Attorneys for the Company.J.L.BEAUDET INC.Avis est par les présentes donné que « J.L.BEAUDET INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des Compagnies et ayant son siège social en la cité de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Québec, ce 17e jour d'octobre 1973.Les procureurs de la compagnie, Gagnon.De Billy, Cantin, 54838-0 Dionne & Martin.J.L.BEAUDET INC.Notice is hereby given that \"J.L.BEAUDET INC.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Québec, will apply to tht Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Québec, this 17th day of October 1973.Gagnon, De Billy, Cantin, Dionne & Martin, 54838-0 Attorneys for the Company.DISTRICT FINANCE CORPORATION LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie «DISTRICT FINANCE CORPORATION LIMITED », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Donné à Montréal, ce 16e jour de novembre 1973.Les procureurs de la requérante, 54840-o Laflbitr & Brown.DISTRICT FINANCE CORPORATION LIMITED Notice is herewith given that \"DISTRICT FINANCE CORPORATION LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Montreal, P.Q., will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 16th day of November.1973.Lafleur & Brown, 54840-o Attorneys for Applicant.MARJOY HOLDINGS LTD.Avis est donné par les présentes que la compagnie « MARJOY HOLDINGS LTD.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 14e jour de novembre 1973.Les procureurs de la requérante, (\"hait.Salomon, Gelber.Reis.54843 Bronstein & Litvack.MARJOY HOLDINGS LTD.Notice is hereby given that \"MARJOY HOLDINGS LTD.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, on this 14th day of November, 1973.Chait, Salomon, Gelber, Reis, Bronstein & Litvack, 54843-0 Attorneys for Applicants. 7012 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 EDIFICE BOUTIN INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « EDIFICE BOUTIN INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnie et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, ce 15e jour de novembre 1973.Les procureurs de la compagnie, Rivard, Hickson, 54841-0 Sirois & Lbmibux.EDIFICE BOUTIN INC.Notice is hereby given that the company \"EDIFICE BOUTIN INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, November 15th, 1973.Rivard, Hickson, Sirois & Lemieux, 54841-0 Attorneys for the Company.LES PLACEMENTS R.H.B.INC.Prenez avis que la compagnie « LES PLACEMENTS R.H.B.INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, 54844-0 Renaud & Renaud.LES PLACEMENTS R.H.B.INC.Notice is given that \"LES PLACEMENTS R.H.B.INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Renaud & Renaud, 54844 Attorneys for the Company.REGENT FINANCE CORPORATION LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie « REGENT FINANCE CORPORATION LIMITED », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Magog.au Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Donné à Montréal, ce 16e jour de novembre 1973.Les procureurs de la requérante.54845-0 Lafleur & Brown.REGENT FINANCE CORPORATION LIMITED Notice is herewith given that \"REGENT FINANCE CORPORATION LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Magog.Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 16th day of November, 1973.Lafleur & Brown, 54845-q Attorneys for Applicant.WE-RO REALTY CORPORATION Avis est donné que la compagnie « WE-RO REALTY CORPORATION ».compagnie ayant son siège social dans les ville et district dc Montréal, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 30 octobre 1973.Le procureur de la compagnie, 54846-0 Peter M.Gold.WE-RO REALTY CORPORATION Notice is given that \"WE-RO REALTY CORPORATION\", corporation having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, October 30, 1973.Peter M.Gold, 54846-q Attorney for the Company.Divers Compagnies Miscellaneous Companies AERO HYDRAULICS CORPORATION LA CORPORATION AERO HYDRAULIQUE La compagnie « AERO HYDRAULICS CORPORATION \u2014 LA CORPORATION AERO HYDRAULIQUE » donne avis qu'elle a diminué dc 9 à 3 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire.Michael J.Ooilvie.54706 13981-61 AERO HYDRAULICS CORPORATION LA CORPORATION AERO HYDRAULIQUE Notice is given that \"AERO HYDRAULICS CORPORATION \u2014 LA CORPORATION AERO HYDRAULIQUE\" has changed the number of its directors from 9 to 3.Michael J.Ogilvie, Secret an/.54706-O 13981-61 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n' L7 7013 SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.» a adopté et décrété le règlement suivant: « Les biens de la compagnie seront distribués entre ses actionnaires proportionnellement au montant d*actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication de ce règlement dans la Gazelle officielle du Québec.» Le procureur de la compagnie, 54698-0 Jean'-Yves Simard, notaire.SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.Notice is hereby given that \"SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.\" has adopted and ordered that: \"The assets of the company will be distributed on a pro rata basis among the shareholders according to their respective rights and interests in the company, fifteen days after the publication of this bylaw in the Québec Official Gazelle.\" Jean-Yves Simard, Notary, 54698-0 Attorney for the company.BEDFORD SALES LTD.La compagnie « BEDFORD SALES LTD.» donne avis quelle a augmenté de 4 à 5 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, Harvey R.Blai\".54707-o 12951-57 CAROCO INC.La compagnie « CAROCO INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, T.H.Bi-ck.54708 737310 CENTCO (CIIATEAUGUAY) LTD.Avis est donné que la compagnie « CENTCO (CHATEAUGUAY) LTD.» a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secret aire-trésorier, Jerry Convoy.54709 723723 DELECTRIC INC.La compagnie « DELECTRIC INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 5.Le secrétaire-trésorier, Leopold Cusack.54711-0 5047-70 FURS BY CHARLES INC.La compagnie « FURS BY CHARLES INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, Betty Cohen.54712 3269-69 INTRAFOR INC.La compagnie «INTRAFOR INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 7.Le secrétaire, Charles A.Veilleux.54715-o 732611 BEDFORD SALES LTD.Notice is given that \"BEDFORD SALES LTD.\" has changed the number of its directors from 4 to 5.54707 Harvey R.Blau, Secretary.12951-57 C VROCO INC.Notice is given that \"CAROCO INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.T.H.Buck, Secretary.5470S-o 737310 CENTCO (CIIATEAUGUAY) LTD.Notice is given that \"CENTCO (CHATEAUGUAY) LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Jerry Convoy.Secretary-Treasurer.54709-o 723723 DELECTRIC INC.Notice is given that \"DELECTRIC INC.\" has reduced the number of its directors from 6 to 5.54711 Leopold Cisack, Secretary-Treasurer.5047-70 FURS BY CHARLES INC.Notice is given that \"FURS BY CHARLES INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.54712-0 Betty Cohen, Secretary.3269-69 INTRAFOR INC.Notice is given that \"INTRAFOR INC.\" has increased the number of its directors from 6 to 7.54715 Charles A.Veilleux, Secretary.732611 7014 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 ORESTION FUR CO.LTD.LA COMPAGNIE DE FOURRURES ORESTION LTEE La compagnie « ORESTION FUR CO.LTD.\u2014 LA COMPAGNIE DE FOURRURE ORESTION LTEE » donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Michel Siassios.54710 721316 ROXHAM PROPERTIES, LIMITED LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE La compagnie « ROXHAM PROPERTIES, LIMITED \u2014 LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE » donne avis qu'elle a augmenté de 5 à 6 le nombre dc ses administrateurs.Le secrétaire, Doris A.Tabah.54714 724445 ORESTION FUR CO.LTD.LA COMPAGNIE DE FOURRURES ORESTION LTEE Notice is given that \"ORESTION FUR CO.LTD.- LA COMPAGNIE DE FOURRURE ORESTION LTEE\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Michael Siassios, Secretary.54710-o 721316 ROXHAM PROPERTIES, LIMITED LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE Notice is given that \"ROXHAM PROPERTIES, LIMITED \u2014 LES IMMEUBLES ROXHAM, LIMITEE\" has changed the number of its directors from 5 to 6.Doris A.Tabah, Secretary.54714-0 724445 MORGAN STANLEY CANADA LIMITED MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE La compagnie « MORGAN STANLEY CANADA LIMITED \u2014 MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE » donne avis qu'elle a augmenté de 9 à 11 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Robert G.Scott.54716 716208 PASCAL-DAWSON LIMITED La compagnie « PASCAL-DAWSON LIMITED » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Arthur Pascal.54717 1704-33 TABCO DEVELOPMENTS INC.LES DEVELOPPEMENTS TABCO INC.La compagnie « TABCO DEVELOPMENTS INC.\u2014 LES DEVELOPPEMENTS TABCO INC.> donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Yi ateur Rouleau.54828 732543 SCOUT INVESTMENT INC.LES INVESTISSEMENTS SCOUT INC.La compagnie « SCOUT INVESTMENT INC.\u2014 LES INVESTISSEMENTS SCOUT INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le secrétaire, Pierre Bélanger.54830-o 733247 MORGAN STANLEY CANADA LIMITED MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE Notice is given that \"MORGAN STANLEY CANADA LIMITED \u2014 MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE\" has changed the number of its directors from 9 to 11.Robert G.Scott, Secretary.54716-0 716208 PASCAL-DAWSON LIMITED Notice is given that \"PASCAL-DAWSON LIMITED\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Arthur Pascal, Secretary.54717-0 1704-33 TABCO DEVELOPMENTS INC.LES DEDELOPPEMENTS TABCO INC.Notice is given that \"TABCO DEVELOPMENTS INC.\u2014 LES DEVELOPPEMENTS TABCO INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.54.S28-0 Vi ateur Rouleau, Secretary.732543 SCOUT INVESTMENT INC.LES INVESTISSEMENTS SCOUT INC.Notice is given that \"SCOUT INVESTMENT INC.\u2014 LES INVESTISSEMENTS SCOUT INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.54830 Pierre Bélanger, Secretary.733247 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, 105' année, n° L7 7015 HYDRAULIC MACHINERY COMPANY, LIMITED La compagnie « HYDRAULIC MACHINERY COMPANY, LIMITED » donne avis qu'elle a augmenté de 5 à 6 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, John A.Ogilvy.54713 1745-47 HYDRAULIC MACHINERY COMPANY, LIMITED Notice is given that \"HYDRAULIC MACHINERY COMPANY, LIMITED\" has changed the number of its directors from 5 to 6.John A.Ogilvy, Secretary.54713-0 1745-47 PLACEMENTS LA RONDELLE LTEE La compagnie « PLACEMENTS LA RONDELLE LTEE » donne avis qu'elle a diminué de 5 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Isabel Candlish.54718 717214 COUVOIR CHABOT LTEE La compagnie « COUVOIR CHABOT LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Jean-Pierre Chabot.54695-0 10863-61 GESTION CAYOUETTE LTEE La compagnie « GESTION CAYOUETTE LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 8 à 6.Le secrétaire, M arien Côté.54829-0 732120 PLACEMENTS PREMIERS NORTH AM ERICA LTEE FIRST NORTHAMERICA INVESTMENTS LTD.La compagnie « PLACEMENTS PREMIERS NORTHAMERICA LTEE \u2014 FIRST NORTHAMERICA INVESTMENTS LTD.- donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 8 à 5.Le secrétaire, 54852-0 David Gilbert.PLACEMENTS LA RONDELLE LTEE Notice is given that \"PLACEMENTS LA RONDELLE LTEE\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Isabel C'andlish, Secretary.54718-0 717214 COUVOIR CHABOT LTEE Notice is given that \"COUVOIR CHABOT LTEE\" has increased the number of its directors from 3 to 4.Jean-Pierre Chabot, Secretary.54695 10863-61 GESTION CAYOUETTE LTEE Notice is given that \"GESTION CAYOUETTE LTEE\" has reduced the number of its directors from 8 to 6.Marien Côté, ¦Secretary.54829 732120 PLACEMENTS PREMIERS NORTHAMERICA LTEE FIRST NORTHAMERICA INVESTMENTS LTD.Notice is given that \"PLACEMENTS PREMIERS NORTHAMERICA LTEE \u2014 FIRST NORTHAMERICA INVESTMENTS LTD.\" has changed the number of its directors from 8 to 5.David Gilbert, 54852-0 Secretary.Curatelle publique Public Curatorship Succession Pierre Bonami Successsion de Bonami, Pierre, en son vivant de St-Lin, décédé le 7 juillet 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessus, le paiement dc toute dette envers la succession et la pveuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec, 9310, boul.St-Laurent, Montréal 354, Que., h2n 1n6.54803-q Estate of Pierre Bonami Estate of the late Bonami, Pierre, in his lifetime of St-Lin, deceased July 7, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec, 9310 St-Laurent Blvd., Montreal 354, Que., h2n 1n6.54803-o 7016 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.A7 Succession Huguette Cayer Succession de Huguette Cayer, en son vivant de Québec, décédée le 16 avril 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent, Montréal 354, Que.H2X 1N6 54819-0 Succession René Lapointe Succesion de René Lapointe, en son vivant de Montréal, décédé le 20 juin 1972.Le sousigné donne avis que sous l'empire dc la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public nu Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal 354.Que.H2N 1N6 54818-0 Ministère des Affaires municipales Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu que l'article 2 de la Loi de l'organisation municipale de certains territoires (chapitre 54 des lois de 1971) édicté que le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer des lettres patentes pour constituer en municipalité toute partie du territoire du Québec qui n'est pas comprise dans une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne et où, de l'opinion du ministre des affaires municipales, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l'immédiat, une municipalité de ville ou dc campagne; Attendu que cette partie du territoire du comté dc Saguenay décrite à la description officielle du ministère des terres et forêts du 11 septembre 1973 est un territoire non organisé au point de vue municipal; Estate of Huguette Cayer Estate of the late Huguette Cayer, in her lifetime of Québec, deceased April 16, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-men-tionned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd.Montreal 354, Que.H2N 1N6 54819-0 Estate of René Lapointe Estate of the late René Lapointe, in his lifetime of Montreal deceased June 20, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent, Blvd., Montreal 354, Que.H2N 1N6 54818-o Department of Municipal Affairs Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.J! ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kindgom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Letters Patent Whereas section 2 of the Act respecting municipal organization of certain territories (Chapter 54 of the Statutes of 1971) stipulates that the Lieutenant-Governor in Council may issue letters patent to constitute as a municipality any part of the territory of the Province of Québec not comprised in a city, town, village or country municipality when, in the opinion of the Minister of Municipal Affairs, it would not be immediately desirable to constitute a town or country municipality; Whereas this part of the territory in the County of Saguenay described in the official description of the Department of Lands and Forests dated September 11, 1973, is an unorganized territory from a municipal point of view: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, 10b' année, n° 17 7017 Attendu que, de l'opinion du ministre des affaires municipales, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l'immédiat, pour cettedite partie du territoire, une municipalité de ville ou de campagne; Attendu Qu'il y a maintenant lieu de délivrer des lettres patentes pour constituer cettedite partie de territoire en une municipalité distincte sous le nom de « Municipalité de Rivière-Pigou » ; Attendu Qu'il y a lieu que ladite municipalité de Rivière-Pigou soit régie par le Code municipal.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3863-73, du 22 octobre 1973.Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes lettres patentes qui entreront en vigueur à compter du jour de leur publication dans la Gazelle officielle du Québec, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des affaires municipales: Que le territoire décrit à la description officielle du ministère des terres et forêts, datée du 11 septembre 1973, comprenant un territoire non organisé au point de vue municipal du comté de Saguenay soit constitué en une municipalité distincte, en vertu de l'article 2 de la Loi de l'organisation municipale de certains territoires (chapitre 54 des lois de 1971), sous le nom de « Municipalité de Rivière-Pigou La description de ce dit territoire est la suivante: Un territoire situé dans le comté municipal de Saguenay, comprenant les cantons de Moisie et de Blanche, une partie des cantons de Rochemonteix et de Charpe-ney.une partie du fleuve Saint-Laurent et une partie non divisée dudit comté, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de la ligne médiane de la rivière Moisie avec le prolongement de la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre J.-Roland Samson en 1960 et portant la désignation * Exploration 249-A »; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en contournant par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'à son embouchure et son prolongement dans le fleuve Saint-Laurent jusqu'à sa rencontre avec une ligne irrégulière parallèle et distante dc un (1) mille de la rive nord-ouest dudit fleuve; ladite ligne irrégulière dans des directions nord-est, sud-est et est jusqu'à sa rencontre avec une ligne droite de direction sud astronomique et originant à l'extrémité sud du cap de Cormorant; ladite ligne droite jusqu'à l'extrémité sud dudit cap; dans le canton de Rochemonteix.une ligne droite de direction nord astronomique sur une distance de six (6) milles; une ligne parallèle à la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent dans une direction nord-est jusqu'à la ligne médiane de la ri\\ière au Bouleau; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive gauche et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive droite jusqu'au prolongement dc la ligne d'arpentage établie sur le terrain par l'arpenteur-géomètre .1.-Roland Samson en Whereas, in the opinion of the Minister of Municipal Affairs, it would not be immediately desirable to constitute, in said part of territory, a town or country municipality; Whereas it is now expedient to issue letters patent to constitute said part of territory into a distinct municipality under the name of \"Municipality of Rivière-Pigou\"; Whereas it is expedient that said Municipality of Rivière-Pigou be governed by the Municipal Code.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 3863-73, dated October 22, 1973, We have decreed and ordered, and by the present letters patent which shall come into force on the date of their publication in the Québec Official Gazelle, do hereby decree and order, upon recommendation of the Minister of Municipal Affairs: That the territory described in the official description of the Department of Lands and Forests, dated September 11, 1973, comprising an unorganized territory from a municipal point of view, in the County of Saguenay, he constituted into a district municipality, under section 2 of the Act respecting municipal organization of certain territories (Chapter 54 of the Statutes of 1971).under the name of \"Municipality of Rivière-Pigou\".The decription of said territory is as follows: A territory located in the municipal County of Saguenay, comprising the Townships of Moisie and Blanche, a part of the Townships of Rochemonteix and of Charpeney, a part of the St.Lawrence River and an undivided part of said County, the whole included within the limits hereinafter described, to wit: Starting from the point of intersection of the median line of Moisie River with the extension of the survey line laid down by J.-Roland Samson, land-surveyor, in 1960 and being designated as \"Exploration 249-A\"; thence, successively, along the following demarcation lines: the median line of said river in a downstream direction and around the right side of the islands nearest to the left shore and around the left side of the islands nearest to the right shore up to the mouth of the river and its extension into the St.Lawrence River up to its meeting point with an irregular parallel line at a distance of one (1) mile from the northwest shore of said river; said irregular line in northeasterly, southeasterly and easterly directions up to its meeting point with a straight line in a direction astronomical south and originating at the southermost point of Cap de Cormorant; said straight line up to the southermost point of said Cape; in the Township of Rochemonteix, a straight line in a astronomical north direction over a distance of six (6) miles; a line parallel to the northwest shore of the St Lawrence River in a northeast direction up to the median line of Rivière-au-Bouleau; the median line of said river in an upstream direction and around the left side of the islands nearest to the left shore and around the right side of the islands nearest to the right shore up to the extension of the survey line laid down by J.-Roland Samson, land-surveyor, in I960, being designated as \"Exploration \"018 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 34, 1973, Vol.105, No.47 1960 et portant la désignation « Exploration 249-A »; ledit prolongement; enfin, ladite ligne d'arpentage jusqu'au point de départ, cette ligne se prolongeant à travers les lacs et les rivières qu'elle rencontre; lesquelles limites définissent un territoire ne possédant pas d'organisation municipale locale distincte, dans le comté municipal de Saguenay, à être érigé en municipalité en vertu du chapitre 54 des lois de 1971 sous le nom de Rivière-Pigou.Que ladite municipalité de Rivière-Pigou soit régie par le Code municipal.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province dc Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour d'octobre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Libro: 1536 Folio: 124 Le sous-procureur général adjoint, Jean Alarie.Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi concernant l'organisation municipale dc certains territoires.Le sous-ministre des affaires municipales, 54861-0 Richard Beaulieu.249-A\"; said extension; lastly, the said survey line up to the starting point, this line extending across lakes and rivers on its way: said limits describing a territory having no distinct local municipal organization, in the municipal County of Saguenay, to be constituted as a municipality under Chapter 54 of the Statutes of 1971, under the name of Rivière-Pigou.That said Municipality of Rivière-Pigou be governed by the Municipal Code.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed ; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-second day of October in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Libro: 1536 Folio: 124 Notice of the granting of the above letters patent is given in conformity with the provisions of section 2 of the Act respecting Municipal organization of certain territories.Richard Beaulieu, 54861 Deputy Minister of Municipal Affairs.Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General.Ventes pour taxes Sales for taxes Cité des Deux-Montagnes Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la Cité des Deux-Montagnes, seront vendus à l'enchère publique, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville, 801 Chemin Oka, Cité des Deux-Montagnes, MARDI, le ONZIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, ainsi que des intérêts courus, plus les frais encourus ou à encourir, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.City of Deux-Montagnes Public notice is hereby given that the immoveables described hereunder, situated in the City of Deux-Montagnes, will be sold by public auction in the council room of the Citv Hall, 801 Oka Road, City of Deux-Montagnes, on TUESDAY, the ELEVENTH day of DECEMBER 1973, at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes with accrued interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.Noms des propriétaires Names o/ proprietors Numéros de cadastre Cadastral numbers P.Bambrick, a/s Me G.Thériault, 44.St-Jean-Baptiste, St-Benoit.68-148; 68-149, avec bâtisse / with building Rudolf Dabas.60-36P; 60-37P.avec bâtisse / with building A.B.Jackson.77-106.avec bâtisse / with building Mrs.H.Merchant, a/s Mr.T.Merchant, P.O.Box 188, Westmount, P.Q.60-243, avec bâtisse / with building Marcel Beaulieu____.97-115 ; 97-116 Wesley Hollinger.80-60; 80-51, avec bâtisse / with building GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, 11° 47 7019 Noms des propriétaires Names of proprietor* Numéros de cadastre Cadastral numbers Angelo Carpini.88-264; 88-265 Angelo Carpini.81-174; 81-175, avec bâtisse / with building Mme Jeanne Myre Bigras, a/s Mme H.Chaurette, 1546 du Tertre, Ste-Foy, 53-293; 53-294 Québec (2).Poulet Frit Coco Rico, a/s Les Amusements G.B.Inc., 3775 Jean Talon Est, 81-64, avec bâtisse / with building Suite 2, Montréal.Mrs.Helda Kaun.80-234; 80-235 L'énumération abrégée des numéros cadastraux des immeubles en question a été autorisée par la Commission municipale du Québec en date du 18 septembre 1973, conformément aux dispositions de l'article 550 de la Loi des cités et villes.Donné à Cité des Deux-Montagnes, ce 9e jour de novembre 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 54656-46-2-0 J.-M.Racine, o.m.a.The abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables in question was authorized by the Québec Municipal Commission on September 18th, 1973 in conformity with the provisions of article 550 of the Cities and Towns Act.Given at City of Deux-Montagnes, this 9th day of November 1973.(Seal) 54656-46-2-0 j.-M.Racine, o.m.a., Secretary-Treasurer.Ville de Saint-Jean Avis public est par la présente donné par la soussignée, greffier de la ville de Saint-Jean, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique, à l'Hôtel de Ville, 188, rue Jacques-Cartier, dans ladite ville, MERCREDI, le DOUZIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires ainsi que des intérêts courus et des frais à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec par décision en date du 5 novembre 1973 a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles sous l'autorité de la Loi des cités et villes, article 550 (S.R.Q., 1964, chapitre 193).City of St.Jean Public notice is hereby given by the undersigned, City Clerk for the City of St.Jean, that the immoveables hereinafter described will be sold by public auction, at the City Hall, 188 Jacques-Cartier Street, in said City, on WEDNESDAY, the TWELFTH day of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon, to cover the payment of municipal and school taxes, plus the accrued interests and costs incurred, unless said taxes, interests and costs are paid prior to the date of sale.By a decision dated November 5, 1973, the Québec Municipal Commission has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the immoveables in conformity with section 550 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, Chapter 193).No de cadastre No de cadastre Noms des propriétaires Names of proprietors de la ville ou No civique Cadastral No.of the town or civic No.de la paroisse ou No civique Cadastral No.of the parish or civic No.Taxes munie.Munie.taxes Taxes scol.School taxes Alrick Entreprises Ltd., CP.63, Iberville.Bât./Bldg.S 932.37 * 1,118.14 Alrick Entreprises Ltd.161.3,978.76 2,685.58 Lucien Clouatre, 271, boul.Séminaire.988-6.604.22 332.36 989-4 Conrad Daneau, 140, Cousins.930 V.862.08 954.64 Denis Caille.618, Raymond.1148-P82 .555.23 547.37 Maurice Choquette, 383, St-Humbert.995-1,996-3, 7,468.16 7,219.27 997-7 994-3,996-1.995-4 René Gosselin, 44A, Marchand.993-1,993-2 1,101.21 957.90 4P 904-1, 994-4P KristeeConstruction Corp., 68, boul.Cartier, Laval-des-Rapides 77-72.78-95P, 937.91 346.14 93P, 78-94P, 77-131P Dalvani Lamoureux, 407, Laurier.418P.783.03 264.72 Dalvani Lamoureux.561.96 211,77 7020 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.17 Noms des propriétaires Names of proprietors No de cadastre de la ville ou No civique Cadastral No.of the town or civic No.No de cadastre de la paroisse ou No civique Cadastral No.of the parish or civic No.Taxes munie.Munie, taxes Taxes scol.School taxes Fcrnand Larose.98, boul.Lenlerc, Granbv.63-510.$ 48.54 8 344i Pierre Marceau, 270, Trahan.206.20.22.23 15.30 Real Pinsonneault, 700, St-.Iacques.108-63,62.1,589.74 2,008.16 Louis-Joseph Roberge.395, Laval.495 .887.60 754.97 Alfred Suprenant, 278, Colhn.108P.43.80 29.51 M.R.H.Timmons, 271, Laurier.354 .545.62 246.85 Les immeubles susdits sont tous aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse et de la ville de Saint-Kean, division D d'enregistrement dc Saint-Jean, et situés dans la ville de Saint-Jean.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Donné à Saint-Jean.Que., ce 12e jour de novembre 1973.Le greffier, .54679-46-2-0 C.Morais, o.m.a.The above-mentioned immoveables are all on the official plan and in the book of reference for the Parish and for the City of St.Jean, St.Jean Registration Division D, and located within the City of St.Jean.Moreover, said sale will include all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveables.Given at St.Jean.Québec, this 12th day of November, 1973.C.Morais, c.m.o., 54679-46-2 City Cleric.Ville de Brossard Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la Ville de Brossard, seront vendus à l'enchère publique, à la Salle du Conseil, 6840 boulevard Matte, Brossard, MERCREDI, le DIX-NEUVIÈME jour de DÉCEMBRE 1973.à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale du Québec a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux.Town of Brossard Public notice is hereby given that the properties described hereunder situated in the Town of Brossard, will be sold bv public auction, in the Council Hall, 6840 Matte Boulevard, Brossard, on WEDNESDAY, the NINETEENTH day of DECEMBER, 1973, at TEN o'clock in the forenoon to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission has authorized and abridged form of cadastral numbers.No rôle Roll No.Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address Cadastre Cadastral Subdivisions 1P08-2-008 André Bélisle, 6140, Poitras.84 34 1P09-1-010 Christian Belair, 6135, Parny.85.84 38,42 1P15-2-004 Berne Const.Ltée, 3503, Ste-Famille.670 82 1P15-2-005 Berne Const.Ltée, 3503, Ste-Famille.670 83 1P27-2-001 Lo Russo Domenico, 3400 Weston, App.603, Toronto, Ontario.78 1 1P27-2-002 Lo Russo Demenico, 3400 Weston, App.603, Toronto, Ontario.78 2 1X03-1-059 Robinson George Allan, 1100 Mc Gregor, App.508 .87 19 et/and 20 1X03-1-064 Robinson George Allan, 1100 Mc Gregor, App.508 .87 15 2R01-1-036 Justin Gallant, 1685, Robert.243 3 2R01-2-032 Mme-Mrs.Edouard Mongrain, 1330, Robert.36 603, 604 2R01-2-032-01 Moreno Const.Ltée.7609, Marie-Victorin.36 605, 607 2R01-2-043 Gaston Rioux, 1650, Robert.36 704.705, 706 2R01-2-048 John Brian Birch, 1730, Robert.243 11 2R02-2-024 Lionel Brin, 3069, Workman, Montréal.37 241,242 2T11-2-004 Habitations Montvillage Inc., 17055, Chemin Ste-Marie.Kirkland.76 1228 2T11-2-005 Kenneth W.Meaker, 1630, Talleyrand.76 1229 3A05-I-008 Joseph Collins, 5935, Adam.121 196 3A06-1-016 Placement Gil-Po Inc., 1180, boul.d'Auteuil, Duvernay, Laval.121 261 3A07-1-007 Roger Lareau, 24, Chemin du Cordon, St-Mathias.122 16-2 3A07-1-007 Roger Lareau.122 17-1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, J05' année, n° 17 7021 No rôle RoU No.Propriétaires \u2014 Adresse Proprietors \u2014 Address Cadastre Cadastral Subdivisions 3A07-1-O07-2 Ronald Lacroix, 2380, Baseline, Ottawa.3A07-2-O19 Sagitaire Inc.a/s-o/s Not.Guy Rivet, 20, Place Crémazie, Ch.1025.3A07-2-O2O Sagitaire Inc.3A08-1-002 Bernard Desjardins, 117.Pasteur, Granby.3A08-1-002 Bernard Desjardins.3A16-1-O01 Corp.de Dev.Monjoie, 7138, Drolet, Montréal.3A16-1-001-I Corp.de Dev.Monjoie.3A16-1-011 Vianna Const.Inc.3A16-1-012 Vianna Const.Inc.3A16-I-013 Vienna Const.Inc.3A16-1-014 Vienna Const.Inc.3A16-2-001 Vienna Const.Inc.3A16-2-002 Vienna Const.Inc.3A16-2-003 Vienna Const.Inc.3A16-2-003-1 Vienna Const.Inc.3A16-2-022 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A16-2-023 Vienna Const.Inc.3A16-2-024 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3a16-2-025 Vienna Const.Inc.3A16-2-026 Vienna Const.Inc.3A16-2-027 Vienna Const.Inc.3A16-2-028 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A16-2-029 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A16-2-030 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A16-2-031 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A16-2-032 Corp.de Dev.Monjoie Ino.3A16-2-033 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A18-1-006 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A18-1-007 Valtes Inc.a/s-c/o Not.Tessier, 201, boul.Churchill, Greenfield Park.3A18-1-008 Valtes Inc.a/s-c/o Not.Tessier.3AI8-1-009 Valtes Inc.a/s-c/o Not.Tessier.3A18-1-O10 Valtes Inc.a/s-c/o Not.Tessier.3A18-2-006 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A21-1-006 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A21-1-007 Yvon Rousseau, 1854, Pine.St-Hubert.3A21-1-008 Yvon Rousseau.3A21-2-006 Corp.de Dev.Monjoie Inc.3A22-1-013 Yvon G.Perreault, 6135, Albanie.3A22-1-023 Jacques Leduc.165, St-Laurent, St-Timothé.3A22-1-029 Monsar Const.Inc.3A22-1-030 Monsar Const.Inc.3A22-1-030-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-031 Monsar Const.Inc.3A22-1-033-I Monsar Const.Inc.3A22-1-034 Monsar Const.Inc.3A22-1-038-1 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-039 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-039-1 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-040 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-O40-1 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-041 The Métropolitain Trust Co.3A22-1-042 Monsar Const.Inc.3A22-1-042-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-43 Monsar Const.Inc.3A22-1-43-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-44 Monsar Const.Inc.3A22-1-45 Monsar Const.Inc.3A22-1-45-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-46 Monsar Const.Inc.3A22-1-46-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-47 Monsar Const.Inc.3A22-1-47-1 Monsar Const.Inc.3A22-1-48 Monsar Const.Inc.3A22-2-001 Yvon Aubut, 6172, Albanie.3A22-2-034 Vienna Const.Inc.3A22-2-035 Vienna Const.Inc.3A22-2-036 Vienna Const.Inc.3A22-2-037 Vienna Const.Inc.¦ \u2022 ¦ \u2022 \u2022 \u2022 ¦ \u2022 ¦ ¦.3A22-2-038 C.C.Const.Inc., 8537, Réjeanne.Ville LaSalle.3A22-2-39 C.C.Const.Inc.3A23-1-009 Corp.de Dev.Monjoie.3A23-1-010 Isganaitis Roman, 2555, Avignon.3A23-1-011 Romstan Ltd.a/s-c/o Roman Isganaitis, 2555.Avignon.122\t17-2 121\t274 121\t275 122\t30 124\t4 126\t86-1 126\t86-2 126\t85-2 126\t87-3, 85-1 126\t87-2 126\t87-1 126\t63-2 126\t62-2, 63-1 126\t61-2, 62-1 126\t61-1 126\t88-2 126\t89-3, 88-1 126\t89-2 126\t90-2.89-1 126\t90-1, 91-2 126\t91-1.92-1 126\t92-2 126\t92-3, 93-1 126\t93-2, 94-1 126\t94-2 126\t94-3, 95-1 126\t95-2 126\t109 126\t110 126\t111 126\t112 126\t113 126\t118 126\t135 126\t134 126\t133 126\t136 127\t345 127\t354 127\t372 127\t373 127\t374 127\t375 127\t379 127\t380 127\t388 127\t389 127\t390 127\t391 127\t392 127\t393 127\t394 127\t395 127\t396 127\t397 127\t398 127\t399 127\t400 127\t401 127\t402 127\t403 127\t404 127\t405 126.127\t153, 369 126\t98-1 126\t99-1, 98-2 126\t100-1, 99-2 126\t100-2 126\t100-3.101-1 126\t101-2 126\t257 126\t258 120\t259 7022 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, No.47 No rôle\tPropriétaires \u2014 Adresse\tCadastre\tSubdivisions \t\t\t Roll No.\tProprietors \u2014 Address\tCadastral\t 3A23-1-012\t\t126\t260 3A23-1-013\t\t126\t261 3A23-1-016\t\t126\t264 3A23-1-017\t\t126\t265 3A23-2-015\t\t126\t255 3A23-2-016\t\t126\t254 3A25-1-012\t\t127\t34 à/to 39 3A25-2-018\t\t126\t280 3A25-2-019\t\t126\t281 3A25-2-020\t\t126\t282 3A25-2-021\t\t126\t283 3A27-2-001\t\t127\t2 3A27-2-O01\t\t127\t81 3A28-1-012\t\t126\t237 3A28-1-013\t\t126\t238 3A28-1-014\tSuce.Claudette B.Tremblay.\t126\t239 3A28-1-015\tSuce.Claudette B.Tremblay.\t126\t240 3A28-1-016\t\t126\t241 3A28-1-017\t\t126\t242 3A28-1-018\t\t126\t243 3A28-1-019\t\t126\t244 3A28-1-020\t\t120\t245 3A29-1-009\t\t120\t202 3A29-1-010\t\t120\t201 3A29-1-013\t\t126\t198 3A29-2-005\t\t120\t274 3A29-2-013\t\t126\t266 3P5O-1-O01\t\t96\t79 3P50-1-O02\t\t00\t78 3P50-1-003\t\t96\t77 3P50-1-004\t\t90\t76 3P50-1-024\t\t96\t60 3ps1-1-017\tKatz, Mme-Mrs.H.\t96\t90 3P51-2-001\t\t90\t80 3P51-2-002\tKatz, Mme-Mrs.H.\t96\tSI 3P51-2-015\t\t90\t94 3P52-2-018\t\t96\t125 4M01-2-012\t\t98\t108-1 4M 10-1-003\t\t102\t62 4M25-1-017\t\t112\t133 4M29-1-028\t\t114\t93 4N07-1-014\t\t95\t66 4O01-2-O02\tMme-Mrs.Raoul Boissé, 3640, Orient.\t231\t3 et/and 4 4O01-2-006\tRoger Broka, 3300, de Falaise, app.611, Ville Mont-Royal.\t231\t8 4X05-1-010\tArthur Seligman, 3645, Sherbrooke, est, Suite 1207, a/s-c/o F.Greenfield.\t96\t156-1-1 4X06-2-143\t\t119\t56 4X06-2-144\tZoltan Collin, a/s-c/o Ralph Welikovitch, 1550, Maisonneuve Ouest-West, Suite 809, Montréal.\t119\t67 4X06-2-180\tGeorges Gottlieb, 1408, Webb Chomedy.\t119\t100 4X06-2-272\tMme-Mrs.Paul Rallion, 33, Bordeaux, France.\t119\t194 5B09-1-041\t\t135\t114 5B09-1-041\t\t136\t360 6B09-1-079\tGuy Fontaine, 6335, Bienville.\t137\t223 6B09-1-079\t\t138\t316 5B09-2-043\tHabitation Montvillage, 17055, Chemin Ste-Marie, Kirkland, Québec.\t136\t548 5B09-2-043\t\t135\t279 5B14-1-018\t\t136\t228 5b19-1-001\t\t136\t446 5B22-1-001\t\t137\t204 6B22-1-001\t\t138\t110 5B24-2-017\t\t139, 140\t428, 162 5B25-2-009\t\t137, 138\t170, 285 5B26-1-012\t\t139, 140\t443, 167 5B26-1-013\t\t139, 140\t444, 168 5B28-1-002\t\t138\t40 6B29-1-003\t\t140\t363 5B37-1-040\t\t140\t184 5B56-2-016\t\t140\t325 5B60-1-003\t\t142\t318 5B60-1-012\t\t142\t327 5B60-1-018\t\t141.142\t268, 333 5B63-1-011\t\t134\t178 5B64-2-004\t\t136\t564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, H novembre 1973, 105' année, n\" 17 7023 5B64-2-017 Windsor Holdings Inc.134, 135 238, 230 5B67-1-001 Habitation Montvillage.135 281 5B67-1-011 P.Germain Senécal, 5520, Boileau.135,136 277,577 6B67-2-008 Habitation Montvillage.134,135 230,270 5B67-2-010 Habitation Montvillage.135 268 5B67-2-011 Habitation Montvillage.135 267 5B67-2-012 Habitation Montvillage.135 266 5X04-2-037 Bert Salomon, 580, Glengarry, Mont-Royal.144 93 5X04-2-038 Katz Miklos & B Bert Salomon, 580, Glengarry.Mont-Royal.144 94, 95 5X10-1-089-1 J.Alfred Marchand, 6135, Matte Boulevard.138,139 340,466 5X10-1-113 Marlotco Quebec Inc.1370, Panama.Brossard.139 187-1 5X10-1-117 Jacques Orchard, 5685, boul.Matte.139 477 5X10-1-120 Glen Furguson, 5645, boul.Matte.139 480 5X10-1-121-1 Joseph Ham Pong, 5625, boul.Matte.139 482 5X10-2-029 Jean-Paul Payette, 6690, boul.Matte.137 91 5X10-2-111 Mme-Mrs.Lucien Malo, 6240, boul.Matte.138 330 5X13-1-002 Habitation Montvillage Inc.134, 135 228, 260 5X13-1-003 Habitation Montvillage Inc.135 261 5X13-1-004 Habitation Montvillage Inc.135 262 5X13-1-005 Habitation Montvillage Inc.135 263 5X13-1-009 Habitation Montvillage Inc.136 579 5X13-1-012 Habitation Montvillage Inc.136 582 5X13-1-013 Habitation Montvillage Inc.136 583 5X13-1-014 Habitation Montvillage Inc.136 584 5X13-1-015 Habitation Montvillage Inc.136 585 5X13-1-023 Albert Dionne, Syndic, 1, Place Ville-Marie.138 129 5X13-1-317 John de la Motte, 5525, Trent Ave., Montréal.153 7 5X13-1-318 Zoltan Collin, 1550, B Maisonneuve ouest-West, Suite 809, Montréal.153 8 5x13-1-421 Zoltan Talus, 6275, Trans Island, Montréal.153 14 5X13-1-425 Cauppauy Villma, AU.: M.L.W.Laroche.29 Gasse, Wien Bezirk XIII, Austria.153 19 à/to 21 5X13-1-426 Mme-Mrs.C.& Mile-Miss L.de Maroth, AU.: M.L.W.Laroche, 29, Gasse, 153 22 Wien Bezirk.XIII.Austria.5X13-1-439 Alex Krauss.1455.Sherbrooke West, Suite 2003.Montréal.153 41 5X13-1-528 M.-Mr.& Mme-Mrs.Alex.Fisher, a/s-c/o M.Colin, 1500, Stanley, suite 809.153 160, 161 Les immeubles susdits sont tous du cadastre de la Paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées aux dits immeubles.Donné en la Ville de Brossard: ce quinzième jour (15e) jour du mois de novembre, mil neuf cent soixante-treize (1973).Le greffier, 54792-47-2-0 Me Claude Desmarais.The above properties are all in the plan and book of reference of the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine.The said sale will be made with all active and passive servitudes apparent or occult, attached to the said properties.Given in the Town of Brossard this fifteen (15th) dav of November, nineteen hundred and seventy-three (1973).Me Claude Desmarais, 54792-47-2-0 Town Clerk.Ville d'Aylmer Avis public est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la ville d'Aylmer que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville de la susdite municipalité, 120, rue Principale MARDI le DIX-NEUVIÈME jour de DÉCEMBRE 1973, à DIX heures de l'ayant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêt, plus les frais subséquemment encourus à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux des immeubles en date du 16 novembre 1973.Town of Aylmer Public notice is hereby given by the undersigned Town Clerk of Aylmer that the properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of the above mentioned Municipality, 120 Main Street on TUESDAY the NINETEENTH dav of DECEMBER 1973, at TEN o'clock in the morning to satisfy the payment of the municipal and school taxes, with interest, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers on the 16th of November 1973.No rôle Propriétaires \u2014 Adresse Cadastre Subdivisions Roll No.Proprietors \u2014 Address Cadastral 7024 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.i7 ., .\u201e Taxes mun.Taxesscol.Rôle Nom des propriétaires No du cadastre int.et frais intérêt Total w Owner s name Cadastral No.Munie, taxes School taxes No.int.and costs interest 0502202\t\t.2175-Pt S\t76.45 8\t105.53 $\t181.98 0503203\t\t\t127.13\t6.82\t133.95 0503208\t\t\t1.32\t13.23\t14.55 0504206\t\t.2177.\t20.42\t204.23\t224.65 0506105\t\t\t298.20\t7.25\t305.45 0506110\tP.D.Quinn.\t.2176-308.\t41.49\t\t41.49 0506111\tP.D.Quinn.\t.2176-309.\t12.95\t\t12.95 0506112\t\t\t96.55\t\t96.55 0506220\t\t\t149.51\t5.57\t155.08 0506404\t\t\t129.04\t\t129.04 0506518\t\t\t353.02\t\t353.02 0506707\t\t.2176-Pt.\t169.06\t\t169.06 0506708\t\t\t260.41\t\t260.41 0507102\t\t\t518.85\t\t618.85 0512105\t\t\t172.67\t\t172.67 0512602\t\t.2021-17.\t198.48\t30.19\t228.67 0513707\tR.Ethier.\t.2069.\t128.85\t\t128.85 0514306\t\t.2085-Pt.\t199.31\t150.03\t349.34 0514405\t\t.2087-Pt.\t338.20\t228.51\t566.71 0514407\t\t\t457.53\t210.61\t668.14 0519403\tI.Charlebois.\t.1498.\t33.01\t127.19\t160.20 0519503\t\t\t13.48\t58.58\t72.06 0520214\t\t.1610.\t52.89\t\t52.89 0520223\t\t.1601.\t703.59\t\t703.59 0528504\t\t.367-1.\t514.78\t\t514.78 0530208\t\t\t13.09\t\t13.09 0530236\t\t\t83.86\t53.92\t137.78 0533510\t\t\t12.27\t\t12.27 0534106\t\t\t166.45\t\t166.45 0535710\t\t\t1.928.09\t861.49\t2,789.58 0538501\t\t\t665.54\t404.39\t1,069.93 0539704\t\t.1763-44.\t576.41\t\t576.41 0539802\t\t\t367.24\t528.55\t895.79 0545206\t\t.1781-56.\t20.03\t\t20.03 \t\t1781-55\t\t\t 0546519\tD.Fortin.\t.1781-5.\t110.39\t\t110.39 0547118\t\t\t9.33\t\t9.33 0547119\t\t\t9.33\t\t9.33 0548511\t\t\t140.60\t\t140.60 0549403\t\t.782-146.\t23.73\t\t23.73 0550311\t\t.11-56.\t151.39\t95.07\t246.46 0552506\tM.A.Griffiths.\t.11-7.\t82.81\t\t82.81 0512603\t\t.2021-18 ____\t19.74\t197.41\t217.15 0513304\t\t\t21.51\t215.07\t236.58 0514606\t\t\t15.01\t150.06\t165.07 0519120\t\t\t12.40\t123.98\t136.38 0519602\t\t.1543.\t23.65\t236.54\t260.19 0519607\t\t\t25.48\t254.79\t280.27 0519707\t\t\t4.85\t48.54\t53.39 0520102\t\t\t25.36\t253.58\t278.94 0527719\t\t\t17.37\t173.74\t191.11 0528408\t\t.Pt 339, Pt 338\t20.98\t209.84\t230.82 0532501\t\t\t3.69\t36.94\t40.63 0538402\t\t\t8.15\t81.45\t89.60 0540108\tG.A.Lebel.\t.766.\t36.93\t369.28\t406.21 0541419\t\t\t8.30\t83.02\t91.32 0542115\t\t.781-338.\t14.57\t145.65\t160.22 0543108\t\t.Pt-9A.\t9.19\t91.93\t101.12 0547117\t\t\t0.92\t9.22\t10.14 0550301\t\t.11-69.\t41.60\t416.03\t457.63 0550317\t\t\t4.76\t47.63\t62.39 0550606\t\too\t1.94\t19.40\t21.34 0551203\t\t\t5.46\t54.66\t60.02 0506108\t\t\t0.94\t9.42\t10.36 0506109\t\t.2176-307.\t0.74\t7.42\t8.16 0522108\t\t\t2.61\t26.06\t28.67 0522428\t\t\t1.48\t14.83\t16.31 0527702\t\t\t1.63\t16.33\t17.96 0520608\t\t\t25.06\t250.64\t275.70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, SA novembre 1973, 105' année, n° A7 7025 No Rôle Roll No.Nom des propriétaires Owner's name No du cadastre Taxes mun.Taxes scol.int.et frais intérêt Cadastral No.Munie, taxes School taxes int.and costs interest Total 0527818 Ent.Roger Pilon.3-128.8 0.73 0547239 H.D.Beinsner.782-246.23.12 Trendsetter Dev.HPt.22,314.70 0506205 P.Sigouin.2176-283 ____ 0.73 7.30 S 8.03 231.22 254.34 22,314.70 7.25 7.98 Donné à Aylmer, P.Q.ce 19e jour du mois de novembre 1973.Le greffier, 54811-47-2-0 André J.Burns, o.m.a.Given at Aylmer, P.Q.this 19th day of November 1973.André J.Burns o.ma., 54811-47-2-0 Town Clerk.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE D'ECONOMIE NOTRE-DAME DC SACRE-COEUR CREDIT UNION (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « LA CAISSE D'ECONOMIE NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR CREDIT UNION », tenue au 811, boulevard Riendeau, à Notre-Dame du Sacré-Coeur, le 13 août 1973, il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite caisse soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit, et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que Me Yves Périgny, avocat, soit nommé liquidateur.Québec, le 18 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54815-0 Albert Jessop.LA CAISSE D'ECONOMIE NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR CREDIT UNION (Saviiigs and Credit Unions Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"LA CAISSE D'ECONOMIE NOTRE-DAME DU SACRE-COEUR CREDIT UNION\", held on August 13, 1973, at 811 Riendeau Boulevard, in Notre-Dame du Sacré-Coeur, it was unanimously resolved that the affairs of said Union be would-up and that it be dissolved, in conformity with the Savings and Credit Unions Act and the Winding-Up Act, and that Me Yves Périgny, lawyer, be appointed liquidator.Québec, October 18, 1973.54815 Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE ST-VALERE (Loi des Caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 13 août 1973 par la « CAISSE POPULAIRE » constituée le 9 février 1937, ayant son siège social à St-Valère et ayant opéré depuis sa fondation sous le nom de « CAISSE POPULAIRE DE ST-VALERE » change son nom de « CAISSE POPULAIRE » pour celui dc « LA CAISSE POPULAIRE ST-VALERE ».Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54817-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE ST-VALERE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on August 13, 1973 by the \"CAISSE POPULAIRE\" incorporated on February 9, 1937, having its head office in St.Valère and having carried on business ever since its institution under the name of \"CAISSE POPULAIRE DE ST-VALERE \", changing its name of \"CAISSE POPULAIRE\" to that of \"LA CAISSE POPULAIRE ST-VALERE\".Québec, October 30, 1973.54817 Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. 7026 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21,, 1973, Vol.105, No.1,7 LA CAISSE POPULAIRE CHARLES LEMOYNE LA CAISSE POPULAIRE CHARLES LEMOYNE (Loi dea caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 21 juin 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE CHARLES LEMOYNE » modifiant son territoire qui était \u2022 celui de la paroisse ecclésiastique de Saint-Jean-Baptiste Marie Yianney » en celui « des Villes de Léry », Châteauguay et Chàteauguay-Centre, comté de Châteauguay ».Québec, le 30 octobre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 54816-0 Albert Jessop.(Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on June 21, 1973 by \"LA CAISSE POPULAIRE CHARLES LEMOYNE\" changing its territory which was \"that of the Ecclesiastical Parish of St.Jean-Baptiste Marie Yianney\" to that of \"the Towns of Léry, Châteauguay and Chàteauguay-Centre, County of Châteauguay\".Québec, October 30, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial 54816 Institutions, Companies and Coopetarives.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ARTHUR CAUX Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a été accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ARTHUR CAUX ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DES SERVICES COMMUNAUTAIRES».Le siège social de l'établissement est à Laurier, district judiciaire dc Québec.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.54695-0 55:66-73 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ST-HENRI Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ST-HENRI ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement sera à Saint-Henri, district judiciaire dc Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.54695-0 55:63-73 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ARTHUR CAUX The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent constituting establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ARTHUR CAUX\".The class to which this establishment shall belong is: \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of the establishment is in Laurier, Judicial District of Québec.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695 55:66-73 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ST-HENRI The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent constituting an establishment under the name of: \"CENTRE LOCAL DE SERVI-( 'ES ( 'OMMl.'NAUTAIRES ST-HENRI\".The class to which this establishment shall belong is: \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of the establishment is in St.Henri, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695 55:63-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n\" 47 7027 CENTRE DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU CENTRE DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1973, fusionnant « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX YAMASKA », constituée le 31 mai 1973 et « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU \u2014 THE RICHELIEU SERVICE CENTER », constituée le 30 mai 1973, toutes les lettres patentes précitées ayant été émises en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971.La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE DE SERVICES SOCIAUX ».Le siège social de l'établissement est à Longueuil, district judiciaire dc Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.54695-0 55:64-73 RESIDENCE BIERMANS Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour d'octobre 1973, convertissant « RESIDENCE MERMAN'S », constituée le 16 janvier 1963, en vertu de la troisième patrie de la Loi des compagnies en un établissement public sous le nom de « RESIDENCE BIERM ANS ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, William Tetley.54695-0 55:62-73 The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated the 22nd hay of October, 1973, amalgamating \"CENTRE DE SERVICES SOCIAUX YAMASKA\", incorporated on Mav 31, 1973 and \"CENTRE DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU \u2014 THE RICHELIEU SOCIAL SERVICE CENTER,\" incorporated on May 30, 1973, all the abovementioned letters patent being issued in compliance with the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971.The class to which this establishment shall belong is: \"SOCIAL SERVICE CENTRE\".The head office of the establishment is in Longueuil, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695 55:64-73 RESIDENCE BIERMANS The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated the 22nd dav of October, 1973, converting \"RESIDENCE BIERMANS\", incorporated on January 16, 1963, under Part III of the Companies Act, into a public establishment under the name of \"RESIDENCE BIERMANS\".The class to which this establishment shall belong is: \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695 55:62-73 Vente d'effets non reclames Sale of Unclaimed Baggage LA CIE DES MESSAGERIES CP LIMITEE Avis est donné par les présentes que tous les effets reçus avant le premier jour de novembre 1972, el non réclamés aux bureaux de « LA CIE DES MESSAGERIES CP LIMITEE » situés à divers endroits dans la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur, par Frank Waddington, commissairc-priseur, 189, rue Queen est, Toronto, (Ontario), à onze heures de l'avant-midi, le 29e jour de novembre 1973, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous frais payés avant cette date.Le vice-président, VV.M.Riley.54127-42-6-0 La Cic des Messageries C.P.limitée.CP EXPRESS LIMITED Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of November, 1972, still remaining unclaimed in the officesof the \"CP EXPRESS LIMITED\" at different points in the Province of Québec, will be sold at Public Auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at 11:00 o'clock in the forenoon, on the twenty-ninth day of November, 1973, unless same shall be called for before that date, and all charges paid thereon.CP Express Limited, W.M.Riley.54127-42-6-0 Vice-President. 7028 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2L, 1973, Vol.105, No.47 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies Institutions, Companies et coopératives and Cooperatives Assurances Insurance LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY Avis de (demande de remise des valeurs) Avis est donné par les présentes, que « LA PROGRESSIVE.COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY », constituée en corporation par lettres patentes conformément aux articles 2 et suivants de la Loi des assurances (S.R.Q.1964.chapitre 295), a réassuré toutes ses obligations découlant de ses contrats d'assurances en vigueur dans le Québec au 31 octobre 1963 auprès de « L'EQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES \u2014 THE EQUITABLE GENERAL INSURANCE COMPANY», constituée en corporation conformément aux dispositions de la section 17 du chapitre III, Titre XI (articles 5,264 et suivants) des Statuts refondus de Québec 1888 et de la Ix)i 7 Edouard VII, chapitre 112, modifiée par la Loi 3 George VI, chapitre 138, enregistrée dans la province, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil le 1er mars -1974, pour obtenir la remise de ses valeurs déposées chez le ministre des finances du Québec.Avis est de plus donné que tous les réclamants actuels ou éventuels, s'opposant à la remise des valeurs dc la compagnie « LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE\u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY », constituée en corporation par lettres patentes, conformément aux articles 2 et suivants de la Loi des assurances (S.R.Q.1964, chapitre 295), doivent produire leur opposition à l'Inspecteur des assurances (Surintendant des assurances), Service des assurances.Hotel du Gouvernement, Québec, le ou avant le 1er mars 1974.Donné à Montréal, ce 19 novembre 1973.Le président, 54862-0 Robert Begin.LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY Avis d'annulation du certificat d'enregistrement Attendu que « LA PROGRESSIVE.COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY » dont le siège social était situé à Montréal, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans le Québec jusqu'au 31 octobre 1963.a, à cette date, réassuré toutes ses affaires dans le Québec avec « L'EQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES \u2014 THE EQUITA- LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY Notice of (application for return of securities) Notice is herebv given that \"THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY \u2014 LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE\", incorporated by letters patent in accordance with sections 2 and following of the Insurance Act (R.S.Q.1964, chapter 295), has reinsured all its obligations deriving from its insurance contracts in force in Québec with \"THE EQUITABLE GENERAL INSURANCE COMPANY \u2014 L'EQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES\" incorporated pursuant to the provisions of section 17 of chapter III, Title XI (sections 5,264 and following) of Revised Statutes of Québec 1888 and Act 7 Edward VII, chapter 112, modified by Act 3 George VI, chapter 138, registered in the province, will apply to the Lieutenant-Governor in Council on the 1st of March 1974, for the release of its securities deposited with the Minister of Finance of Québec.Notice is hereby further given that all claimants, actual or eventual, opposing the release of the securities of \"THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY \u2014 LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE\", incorporated by letters patent in accordance with section 2 and following of the Insurance Act (R.S.Q.1964, chapter 295), must file their opposition with the Inspector of Insurance (Superintendent of Insurance), Department of Insurance, Government House, Québec, on or before the 1st of March 1974.Given at Montreal, this 19th of November, 1973.Robert Begin, 54862-0 President.LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY Notice of Cancellation of Certificate of Registration Whereas \"LA PROGRESSIVE.COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY\" whose head office was situated at Montreal which company was duly authorized to do business in Québec, till the 31st of October 1963, has.at this date, reinsured all its business in Québec with \"L'EQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES \u2014 THE EQUITABLE GENERAI. GAZETTE CEE ICI ELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° 47 7029 BLE GENERAL INSURANCE COMPANY > dont le siège social est situé à Montréal, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 31 octobre 1963; Attendu que « L'EQUITABLE.COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES \u2014 THE EQUITABLE GENERAL INSURANCE COMPANY » est dûment autorisée à faire affaires dans le Québec; Attendu que « LA PROGRESSIVE.COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY» s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le certificat d'enregistrement de « LA PROGRESSIVE.COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY » est annulé à compter du 31 octobre 1963.Donné au bureau du service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 8 novembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province.Le surintendant des assurances.54648-46-2-0 Roger-A.Camaraihe.INSURANCE COMPANY\" whose head office is situated at Montreal, according to a reinsurance agreement entered into bv these two companies on the 31st of October 1963; Whereas \"L'EQUITABLE, COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES \u2014 THE EQUITABLE GENERAL INSURANCE COMPANY\" is duly authorized to do business in Québec; Whereas \"LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INRU-ANCE COMPANY\" has complied with the provisions of section 103 of the Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the certificate of registration of \"LA PROGRESSIVE, COMPAGNIE D'ASSURANCE \u2014 THE PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY\" is cancelled as from the 31st.of October 1963.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, the 8th of November 1973.For the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province, Rogeh-A.Camaraire, Ô4648-16-2-0 Superintendent of Insurance.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses \\RKANSAS-BEST FREIGHT SYSTEM, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « ARKANSAS-BEST FREIGHT SYSTEM, INC.», a reçu l'autorisation de faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd.220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre associé des institutions, financières, compagnies tt coopératives, Albert Jessop.54695 PA: 84-73 ARKANSAS-BEST FREIGHT SYSTEM, INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"ARKANSAS-BEST FREIGHT SYSTEM, INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, Judicial District of Québec.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695-0 PA: 84-73 ATL VNTIC RESOURCE CONSULTANTS LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « ATLANTIC RESOURCE CONSULTANTS LIMITED » a reçu l'autorisation de faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Douglas S.Pryde, a/s O'Brien, Hall.Saunders, 2100, Place Canada, Montréal.ATLANTIC RESOURCE CONSULTANTS LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"ATLANTIC RESOURCE CONSULTANTS LIMITED\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the companv is Mr.Douglas S.Pryde, c/o O'Brien, Hall, Saunders, 2100 Place Canada, Montreal. 7030 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21.1973, Vol.105, So.i7 Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 2100, Place Canada, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.54695 PA:2-73 The principal office of the company in the Province is at 2100 Place Canada, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies aiui Cooperatives.54695-0 PA: 2-73 El.PASO MINING AND MILLING COMPANY Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « EL PASO MINING AND MILLING COMPANY » a reçu l'autorisation de faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et.coopératives, Albert Jessop.54695 PA: 81-73 EL PASO MINING AND MILLING COMPANY Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act.\"El.PASO MINING AND MILLING COMPANY\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, Judicial District of Québec.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54695-0 PA: 81-73 KENN DEVELOPMENT CORPORATION Avis est donné qu'en vertu de la \\a>\\ des compagnies étrangères, la compagnie « KENN DEVELOPMENT CORPORATION » a reçu l'autorisation de faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Michael Dennis, 630, boulevard Dorchester ouest 22e étage, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 630, boulevard Dorchester ouest, 22e étage, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.54695 PA: 72-73 MSI DATA CORPORATION Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « MSI DATA CORPORATION » a reçu l'autorisation de faire des affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur J.B.McMullan, a/s Lafleur & Brown, 800, Carré Victoria, suite 720, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 800, Carré Victoria, suite 720, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre associé des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.54695 PA: 66-73 KENN DEVELOPMENT CORPORATION Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"KENN DEVELOPMENT CORPORATION\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Michael Dennis, 22nd Floor, 630 Dorchester Boulevard West.Montreal.The principal office of the company in the Province is at 22nd Floor, 630 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, 54695-0 PA: 72-73 MSI DATE CORPORATION Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"MSI DATA CORPORATION\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.J.B.McMullan, c/o Laflcur & Brown, Suite 720, 800 Victoria Square, Montreal.The principal office of the company in the Province is at Suite 720, 800 Victoria Square, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Associate Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.54695-0 PA: 66-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2i novembre 1973, 105' année, n° 47 7031 Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Cilé de Beaconsfield Comté de Pointe-Claire Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Allen Mainville, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville 303.Boulevard Beaconsfield, Ville de Beaconsfield, comté de Pointe-Claire, P.Q.jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 10 décembre 1973 pour l'achat de $1.000.000 d'obligations de la cité de Beaconsfield, comté de Pointe-Claire, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 §1.000,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 01 1975.820,000 01 01 1976.23,000 01 01 1977.24,000 01 01 1978.27,000 01 01 1979.29,000 01 01 1980.31,000 01 01 1981.34,000 01 01 1982.37,000 01 01 1983.40.000 01 01 1984.43,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 896,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1994.City of Beaconsfield County of Pointe-Claire Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Allen Mainville, Secretary-Treasurer, at the City Hall.303 Beaconsfield Boulevard, City of Beaconsfield, County of Pointe-Claire, Québec, until 8:30 o'clock p.m.on Monday, December 10, 1973, for the purchase of a bond issue of $1,000.000 for the City Beaconsfield, County of Pointe-Claire, dated January 1, 1974 and redeemable serially from January 1, 1975 to January 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Redemption table \u2014 SI,000,000 \u2014 20 years \tDate\t\tCapital 01\t01\t1985.\t.$47,000 (11\t01\t1986.\t.51,000 01\t01\t1987.\t.55,000 01\t01\t1988.\t.60,000 01\t01\t1989.\t.65,000 01\t01\t1990.\t.71,000 (11\t01\t1991.\t.76,000 01\t01\t1992.\t.82,000 01\t01\t1993.\t.89,000 (11\t1)1\t1994.\t.96,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than 896,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 1.1994. 7032 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 24, 1973, Vol.105, So.47 Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $96,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à \\% du montant de l'emprunt.La cité de Beaconsfield s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 394 \u2014 $1,000,000 \u2014 construction d'un centre récréatif.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.30 heures du soir, lundi, le 10 décembre 1973, Hôtel de ville, 303, Boulevard Beaconsfield, Ville de Beaconsfield, comté de Pointe-Claire.P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Beaconsfield (Comté de Pointe-Claire), ce 15 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier, Allen Mainvillk.Hôtel de ville, 303.Boulevard Beaconsfield.Beaconsfield, (Pointe-Claire), P.Q.Téléphone: 697-4660.code 514.54796-o Village de Deschcnes Comté de Gatineau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné M.Gilles-A.Dupont, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville.48 rue Principale.Deschênes, comté dc Gatineau.P.Q., jusqu'à 7.00 heures du soir, mercredi le 12 décembre 1973 pour l'achat de $261,500 d'obligations du village de Deschênes, comté de Gatineau, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $96.000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to l%of the amount of the loan.The City of Beaconsfield agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.- - The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 394 \u2014 $1,000,000 \u2014 construction of a recreational centre.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at8:30 o'clock p.m., on Monday, December 10, 1973, at the City Hall, 303 Beaconsfield Boulevard, City of Beaconsfield, County of Pointe-Claire, Québec.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Beaconsfield (Countv of Pointe-Claire), November 15, 1973.Allen Mainville, Secretary-Treasurer.City Hall, 303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield, (Pointe-Claire), Québec.Telephone: 697-4660, code 514.54796 Village of Deschcnes County of Gatineau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mr.Gilles-A.Dupont, Secretary-Treasurer, Town Hall, 48 Main Street, Deschênes, County of Gatineau, P.Q., until 7:00 o'clock p.m., on Wednesday December 12, 1973, for the purchase of a bond issue of $261,500 of the Village of Deschênes, County of Gatineau, dated January 1, 1974 and redeemable serially from January 1, 1975 to January 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than S%, nor more than 9%, payable semiannually on January 1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année.n° 17 7033 payable semi-annuellment les 1er janvier et 1er juillet dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculéà compterdu 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 «261,500 \u2014 20 ans Date Capital 01 01 1975.3 6,000 01 01 1976.6.500 01 01 1977.7.000 01 01 1978.7,500 01 01 1979.8,000 01 01 1980.8.500 01 01 1981 .9,500 01 01 1982.10,000 01 01 1983.11.000 01 01 1984.11.500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3e Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $23.500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédant ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'ci héances excluant l'échéance du 1er janvier 1994.C pendant, les soun.is ions ne devront être transmis s que jour un seul d.s medes d'émission ci-haut et n.- devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto.Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $23,500 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er janvier dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission and July 1 of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Hedemption table \u2014 8261,500 \u2014 9.0 years Date Capital 01 01 1985.$12,500 01 01 1986.13,500 01 01 1987.14,000 01 01 1988.15,000 01 01 1989.17,000 01 01 1990.18,500 01 01 1991.19,500 01 01 1992.20,500 01 01 1993 .22,000 01 01 1994 .23,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $23,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 1.1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exemptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the main office of said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they arc issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $23,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 1 of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the 7034 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, November Sk, 1973, Vol.105, No.17 conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant dc l'emprunt.Le village de Deschênes s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 180 \u2014 $261,500 \u2014 Renouvellement d'emprunt.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 12 décembre 1973 à 7.00 heures du soir, Hôtel de ville, 48.rue Principale, Deschênes, comté de Gatineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Deschênes.(Comté de Gatineau), ce 15 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier.Monsieur Gilles-A.Dupont.Hôtel de ville, 48.rue Principale, Deschênes, Comté de Gatineau.Québec.Téléphone: 684-3757.code 819.54797-o Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Comté de Bcauce-Nord Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jacques Giguère, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, C.P.88, Saint-.Ioseph-de-Beauce, comté de Beauce-Nord, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mercredi le 12 décembre 1973, pour l'achat de $155,000 d'obligations de la ville de Saint-.Ioseph-de-Beaucc, comté de Beauce-Xord, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.I,e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $155,000 \u2014 10 ans Date Capital 01 01 1975.$10,000 01 01 1976.11,000 01 01 1977.12,000 01 01 1978.13,500 01 01 1979.14,500 On est prié dc noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Village of Deschênes agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974 without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 180 \u2014 $261,500 \u2014 loan renewal.Tenders shall be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, December 12, 1973, at 7:00 o'clock p.m., in the Town Hall, 48 Main Street, Deschênes, County of Gatineau, P.Q.The Council docs not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Deschênes, (County of Gatineau) this November 15, 1973.Mr.Gii.les-A.Dupont, Secretary-Treasurer.Town Hall, 48 Main Street, Deschênes, County of Gatineau, Québec.Telephone: 684-3757, code 819.54797 Town of St.Joseph-de-Beauce County of Beauce-North Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jacques Giguère, Secretary-Treasurer, at the Town Hall.P.O.Box 88.St.J_oseph-de-Beauce, County of Beauce-North, P.Q.until 7:30 o'clock p.m., on Wednesday.December 12.1973, for the purchase of a bond issue of 8155,000 for the Town of St.Joseph-de-Beauce, County of Beauce-North, dated January 1, 1974.and redeemable serially from January 1, 1975, to January 1, 1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%.payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Rédemption table \u2014 8155,000 \u2014 10 years Date Capital 01 01 1980.$15,500 01 01 1981.17,000 01 01 1982.19,000 01 01 1983.20,500 01 01 1984.22,000 It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2i novembre 1973.105' année, n\" 47 7035 faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.I, adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Saint-Joseph-de-Beauce s'engage à ne pa> émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 284 \u2014 $155,000 \u2014 consolidation dc déficit.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue mercredi le 12 décembre à 7.30 heures du soir.Hôtel de ville, CP.88.Saint-Joseph-de-Beauce, comté de Beauce-N'ord, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Joseph-de-Beaucc (Comté de Beaucc-Nord), ce 16 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier.Jacques Gl(h ère.Hôtel de ville, CP.88.Saint-Joseph-de-Beauce, Comté de Beauce-Xord, P.Q.Téléphone: 397-5326, code 418.54856-o .Municipalité de Grande-Vallée Comté de Gaspé-Est Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné M.Charles Emile Minville.secrétaire-trésorier, jusqu'à 5 heures de l'après-midi.Bureau municipal, CP.98, Grande-Vallée, comté de (Jaspé-Est, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir.Centre municipal C.P.98.Grande-Vallée, comté de Gaspé-Est, mardi le 11 décembre 1973, pour l'achat de $124,000 d'obligations de la municipalité de Grande-Vallée, comté de Gaspé-Est, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.I-e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, 1 intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.considered.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest arc payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Joseph-de-Beauce agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974.without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 284 \u2014 8155.000 \u2014 consolidation of deficit.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be.to he held on Wednesday.December 12, 1973, at*7:30 o'clock p.m.at the Town Hall, P.O.Box 88, St.Joseph-de-Beauce, County of Beauce-North.P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Joseph-de-Beauce (County of Beauce-North), November 16, 1973.Jacques Giguère, Secretary-Treasurer.Town Hall, P.O.Box 88, St.Joseph-de-Beauce, County of Beauce-North, P.Q.Telephone: 397-5326.code 418.54856 Municipality of Grande-Vallée County of Gaspé-East Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mr.Charles-Emile Minville, Secretary-Treasurer, on Tuesday.December 11, 1973, until 5:00 o'clock p.m.at the Municipal Office, P.O.Box 98, Grande-Vallée, County of Gaspé-East, P.Q.and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Municipal Centre, P.O.Box 98, (ïrande-Vallée, County of Gaspé-East, for thepurcha.se of a bond issue of 8124,000 for the Municipality of Grande-Vallée, County of Gaspé-East.dated January 1, 1974 and redeemable serially from January 1, 1975 to January 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover oneor several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974. 7036 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2',, 1973, Vol.105, No.A7 Tableau d'amortissement \u2014 8124,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 01 1975.S 5,000 01 01 1976.5,500 01 01 1977 .6,000 01 01 1978 .6,500 01 01 1979 .7,000 01 01 1980.8,000 01 01 1981.8,500 01 01 1982 .9,500 01 01 1983.10,000 01 01 1984.11,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 84,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er janvier 1994 au montant de $35,000 comprend un solde de 833,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 01 01 1995.$2,000 01 01 1996.2,500 01 01 1997 .2,500 01 01 1998.3,000 01 01 1999.3,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf is elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $35,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel Rédemption table \u2014 $124,000 \u2014 20 years Date CapiUl 01 01 1985.8 1,000 01 01 1986.1.000 01 01 1987.1.000 01 01 1988.1.000 01 01 1989.1,500 01 01 1990.1,500 01 01 1991.1.500 01 01 1992.1,500 01 01 1993.2,000 01 01 1994.35,000 Moreover the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with, the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-teim bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $4,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of January 1, 2004 of the renewable part hereinafter described.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of January 1, 1994 in the amount of 835.000 includes a balance of 833,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 01 01 2000.$3,500 01 01 2001.3,500 01 01 2002.4,000 01 01 2003.4,500 01 01 2004 .4,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $35,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n\" 47 7037 requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La municipalité de Grande-Vallée s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: 31\u20148124,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 11 décembre 1973, à 8 heures du soir.Centre municipal de Grande-Vallée, CP.98, comté dc Gaspé-Est, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cirande-Vallée (Comté de Gaspé-Est), ce 16 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier, M.Charles-Emile Minville.Bureau municipal, C.P.98, Grande-Vallée, comté de Gaspé-Est, P.Q., Téléphone: 151, code 418.54798-0 Ville de Senneterre Comté de Abitibi-est Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Marcel Mirault, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 551, 10e Avenue, C.P.789.Senneterre, comté d'Abitibi-est.P.Q.jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi le 10 décembre 1973, pour l'achat de 8119,000 d'obligations de la ville de Senneterre, comte d'Abitibi-est, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%.ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $119.000 \u2014 10 ans Date Capital 01 01 1975.S 8,000 01 01 1976.8,500 01 01 1977 .9.500 01 01 1978.10.500 01 01 1979.11000 to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Municipality of Grande-Vallée agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974.without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued according to the following bylaw: 31 \u2014 8124,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday.December 11.1973, at 8:00 o'clock p.m.at the Municipal Centre of G rande-Val lee.P.O.Box 98.Countv of Gaspé-East, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Grande-Vallée (Countv of Gaspé-East), November 16.1973.Mr.Charles-Emile Minville, Secretary-Treasurer.Municipal Office, P.O.Box 98.Grande-Vallée.County of Gaspé-East, P.Q., Telepone: 151, code 418.54798 Town of Senneterre County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Marcel Mirault.Secretarv-Treasurer, at the Town Hall, 551 - 10th Avenue, P.Q.Box 789.Senneterre.County of Abitibi East.P.Q.until 8:00 o'clock p.m., on Monday, December 10, 1973.for the purchase of a bond issue of 8119,000 for the Town of Senneterre.County of Abitibi-East, dated January 1, 1974 and redeemable serially from January 1, 1975 to January 1, 1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than a rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication pruposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Redemption table \u2014 SI 19,000 \u2014 10 years Date Capital 01 01 1980.812,000 01 01 1981.13,000 01 01 1982.14,500 01 01 1983.15.000 01 01 1984.17.000 7038 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November tL, 1973, Vol.105, No.47 On est prie de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province dc Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation-Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Senneterre s'engage à ne pas émettre dc nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974.sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 203 \u2014 827.600 \u2014 aqueduc, égout voirie; 210 \u2014 857,400 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 212 \u2014 $34,000 \u2014 achat d'équipemi nt.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas.qui sera tenue lundi le 10 décembre 1973 à 8.00 heures du soir, Hôtel de ville.551, 10e Avenue, C.P.789, Senneterre.comté d'Abitibi-est P.Q.Le conseil se réserve de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Senneterre (Comté d'Abitibi-est).ce 19 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier, Marcel Mirault.551, 10e Avenue, C.P.789, Senneterre, Comté d'Abitibi-est Québec.Téléphone: 737-2296.code 819.54857-o Ville de La Pocatière Comté de Kamouraska-Témiscouata Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Claude Crête, greffier.Hôtel de ville.412, Boulevard Desrochers, La Pocatière.comté dc Kamouraska-Témiscouata.P.Q.jusqu'à 7.30 heures du soir, mardi, le 11 décembre 1973.pour l'achat de $256,000 d'obligations de la ville de La Pocatière, comté de Kamouraska-Témiscouata.datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1994 inclusivement avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified check.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Senneterre agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 203 \u2014 827,600 \u2014 waterworks, sewers, roads; 210 \u2014 $57,400 \u2014 waterworks, sewers, roads; 212 \u2014 $34,000 \u2014 purchase of equipment.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case may be.to be held on Monday, December 10.1973.at 8:00 o'clock p.m.at the Town Hall.551-10th Avenue, P.O.Box 789, Senneterre, Countv of Abitibi-East, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Senneterre (County of Abitibi-East).November 19.1973.Marcel Mirault, Secretary- Treasurer.551-10th Avenue.P.O.Box 789.Senneterre.Countv of Abitibi-East.P.Q.Telephone: 737-2296.code 819.54857 Town of La Pocatière County of Kamouraska-Témiscouata Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Claude Crête, Town Clerk, at the Town Hall.412 Desrochers Boulevard, La Pocatière, County of Kamouraska-Témiscouata.P.Q.until 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, December 11, 1973, for the purchase of a bond issue of $256,000 for the Town of i.a Pocatière, County of Kamouraska-Témiscouata, dated January 1, 1974, and redeemable serially from January 1.1975 to January 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%.nor more than 9%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 novembre 1973.105' année.n° 47 7039 amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 8256.000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 01\t01\t1975.\t.$ 7,000 01\t01\t1976.\t.7,500 01\t01\t1977.\t.8,000 01\t01\t1978.\t.8.000 01\t01\t1979.\t.8.000 01\t01\t1980.\t.8.000 01\t(Il\t1981.\t.9,000 (11\t01\t1982.\t.9.000 01\t01\t1983.\t.9,000 01\t01\t1984.\t.9,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixème année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $8.500, el si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 2014 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er janvier 1994 au montant île $106,000 comprend un solde de 895,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans.et échéant comme suit: Date Capital 01 01 1995.$2.000 01 01 1996.2,500 01 01 1997 .2,500 01 01 1998 .2,500 01 01 1999 .3,000 01 01 2000.3.000 01 01 2001.3,000 01 01 2002 .4,000 01 01 2003 .4.000 01 01 2004 .4.000 shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Redemption table \u2014 $256.000 \u2014 20 years Date Capital 01 01 1985.$ 5,000 01 01 1986 .5,500 01 01 1987 .6,000 01 01 1988 .7,000 01 01 1989.7.500 01 01 1990 .8,500 01 01 1991.8,500 01 01 1992.9,500 01 01 1993.9,500 01 01 1994.106,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $8,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of January 1.2014 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of January 1, 1994 in the amount of $106.000 includes a balance of $95.500 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 01 01 2005.$4.500 01 01 2006.4.500 01 01 2007 .5,500 01 01 2008 .5,500 01 01 2009.6,000 01 01 2010 .7.000 01 01 2011.7.000 01 01 2012 .8.000 01 01 2013 .8.500 01 01 2014.8.500 7040 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November gi, 1973.Vol.105, No.17 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indique dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $106.000.et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant dc l'emprunt.La ville de La Pocatière s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 2-73 \u2014 $75,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 3-73 \u2014 $54,100 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 6-72 \u2014 $29,000 \u2014 voirie; 6-73 \u2014 $46.500 \u2014 achat d'équipement; 8-72 \u2014 $38.400 \u2014 voirie; 10-71 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un dc ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 7.30 heures du soir, mardi, le 11 décembre 1973.Hôtel de ville.412.Boulevard Desrochers.La Pocatière.comté de Kamouraska-Témiscouata, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.La Pocatière (Comté de Kamouraska-Témiscouata).ce 16 novembre 1973.Le greffier, Claude Crête.Hôtel de ville.412.Boulevard Desrochers, La Pocatière, (Kamouraska-Témiscouata).P.Q.Téléphone: 856-3394.code 418.54799-0 Ville dWylmcr Comté de Gatineau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné André J.Burns, greffier.Hôtel de Ville, 120, rue Principale, Aylmer, comté de Gatineau, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 10 décembre 1973, pour l'achat de $1,895,500 d'obligations de la ville d'Aylmer, comté dc Gatineau, datées du 1er janvier 1974 et remboursables en série du 1er janvier 1975 au 1er janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellemcnt les 1er juillet et 1er janvier dc chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute rémission; The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of said bank in Toronto, Ontario.The said Irands will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 10-year fixed-term bonds for an amount greater than $106,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of La Pocatière agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 2-73 \u2014 $75,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 3-73 \u2014 $54.100 \u2014 waterworks, sewers and roads: 6-72 \u2014 $29.000 \u2014 roads; 6-73 \u2014 $46,500 \u2014 purchase of equipment; 8-72 \u2014 $38,400 \u2014 roads; 10-71 \u2014 $13,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case mav be, to be held at 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, December 11, 1973, at the Town Hall, 412 Desrochers Boulevard, La Pocatière, County of Kamouraska-Témiscouata, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.La Pocatière (County of Kamouraska-Témiscouata), November 16, 1973.Claude Crête, Town Clerk: Town Hall, 412 Desrochers Boulevard, La Pocatière (Kamouraska-Témiscouata), P.Q.Telephone: 856-3394, code 418.54799 Town of Aylmer County of Gatineau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.André J.Burns, Town Clerk, at the Town Hall.120 Main Street, Aylmer, County of Gatineau P.Q.until 8:00 o'clock p.m., on Monday December 10.1973 for the purchase of a bond issue of $1,895,500 for the Town of Aylmer.County of Gatineau.dated January 1.1974, and redeemable serially from January 1, 1975 to January 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%.payable semiannually on July 1st and January 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 novembre 1973, 105' année, n° 17 7041 cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,895,500 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 01\t01\t1975.\t.$ 51,500 01\t(11\t1976.\t.56,000 01\t01\t1977.\t.61,000 01\t01\t1978.\t.66,000 01\t(11\t1979.\t.73,000 01\t01\t1980.\t.80,000 01\t01\t1981.\t.87,000 01\t01\t1982.\t.95,000 01\t01\t1983.\t.104,000 01\t01\t1984.\t.113,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligation échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $158,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er janvier 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, et à Ottawa, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $158,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 1, 1974.Redemption table \u2014 $1,895,500 \u2014 20 years Date Capital 01 01 1985.$ 74,000 01 01 1986.80,000 01 01 1987.87,000 01 01 1988.95,000 01 01 1989.103,000 01 01 1990.112,000 01 01 1991.121,000 01 01 1992.134,000 01 01 1993.145,000 01 01 1994.158,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $158.000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 1, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of said bank in Toronto and Ottawa.Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $158.000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice. 7042 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.106, No.i7 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville d'Aylmer s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 343-A \u2014 SI,500,000 \u2014 aqueduc et égouts: 345 \u2014 $21,000 \u2014 aqueduc et égouts: 360 \u2014 $125,000 \u2014 égouts; 366 \u2014 $145,000 \u2014 éclairage; 368 \u2014 $104,500 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, lundi, le 10 décembre 1973, Hôtel de Ville, 120, rue Principale, Aylmer, comté de Gatineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Aylmer (Comté de Gatineau), ce 19 novembre 1973.Le greffier, André J.Burns.Hôtel de Ville, 120, rue Principale, Aylmer, (Gatineau).P.Q.Téléphone: 684-5372, code 819.54855-o Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Aylmer agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 343-A \u2014 $1,500,000 \u2014 waterworks and sewers; 345 \u2014 $21.000 \u2014 waterworks and sewers; 360 \u2014 $125,000 \u2014 sewers; 366 \u2014 $145,000 \u2014 lighting; 368 \u2014 $104,500 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Monday December 10.1973.at the Town Hall, 120 Main Street, Aylmer, County of Gatineau, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Aylmer (County of Gatineau), November 19, 1973.André J.Burns, Town Clerk.Town Hall, 120 Main Street, Avlmer, Gatineau.P.Q.Telephone: 684-5372, code 819.54855 Demandes à la Législature Applications to Legislature CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC.Avis est par les présentes donné que le « CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC-, s'adressera à l'Assemblée Nationale pour obtenir une loi spéciale transformant et augmentant son capital-actions et imposant certaines obligations à une classe d'actionnaires.La loi spéciale contiendra des dispositions pour: a) annuler les actions actuelles et les remplacer par des actions classe « A » d'une valeur au pair de $500, rachetables et comportant priorité sur le produit d'une liquidation; b) créer 800 actions classe « B » dont le détenteur sera sujet à des cotisations annuelles et à des cotisations spéciales; c) autoriser le conseil d'administration à fixer les conditions d'achat des actions classe « B » sous forme de droit d'entrée ou de droit de transfert; d) autoriser la confiscation des actions classe « B » en cas de non paiement des cotisations annuelles et spéciales et de défaut de payer les comptes de dépense; (e) accorder au conseil d'administration le droit dc faire des règlements sur les conditions d'admission, les cas d'expulsion et l'imposition de cotisations annuelles et spéciales.Donné à Joliette, ce 10e jour de septembre 1973.Les procureurs de la requérante, 54858-47-4-0 Dug as, Dugas & Gagnon.CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC.Notice is herebv given that \"CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC.\", will apply to l'Assemblée Nationale for a special Act increasing the share capital, transfoim-ing the share structure and obliging class \"B\" shareholder to duties and contributions.The special Law will: (a) replace shares now issued with class \"A\" shares, having a par value of $500, redeemable and having priority in liquidation; (6) issue 800 class \"B\" shares, subject to annual dues and special dues; (c) give authority to the Board of Directors to enact conditions for the purchases of class \"B\" shares and assess entry fees or transfer fees; (d) give authority to the Board to confiscate class \"B\" shares for non payment of the annual dues, special assessment and expense accounts; (e) authorize the Board of Directors to enact bylaws on conditions of admission, circumstances of expulsion, annual dues and special assessments.Joliette, September 10, 1973.Dugas, Dugas & Gagnon, 54858-47-4-0 Attorneys for plaintiff. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n° J,7 7043 Église Béthanie Avis public est donné par les présentes que l'Église Béthanie, une Eglise protestante particulière selon la Loi de la constitution de certaines Églises, 1964 R.S.Q., c.305, s'adressera au lieutenant-Gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'acquisition des pouvoirs d'un corps constitué en corporation, le tout suivant ladite Loi de la constitution de certaines Églises.Montréal, ce 30e jour d'octobre 1973.Les procureurs de la requérante, Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, 54568-45-4-0 Phelan & Mackell.Église Béthanie Public notice is hereby given that Église Béthanie, an individual Protestant Church within the meaning of the Church Incorporation Act.1964 R.S.Q., ch.305, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for incorporation under the said Church Incorporation Act.Montreal, this 30th day of October 1973.Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan & Mackell, 54568-45-4-0 Attorneys for Petitioner.FIDUCIE PRET ET REVENU PRET ET REVENU LTEE Avis est donné que « FIDUCIE PRET ET REVENU » et « PRET ET REVENU LTEE », corporations ayant leurs sièges sociaux dans la V'\"e de Ôtt**M\"\\ déposeront au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale du Québec un projet de loi les fusionnant en une nouvelle corporation sous le iniu uc « FIDUCIE PRET ET REVENU » en français, et » SAVINGS AND INVESTMENT TRUST » en anglais, avec un capital autorisé de S6.000.000 divisé en 300,000 actions classe « A » d'une valeur au pair de $10 et 300,000 actions classe « B » d'une valeur au pair de 810 aux fins d'exercer généralement toutes les activités d'une compagnie de fidéicommis, avec les pouvoirs décrits dans la Loi des compagnies de fidéicommis, (S.R.Q.1964, chap.287, et certains autres pouvoirs ancillaires.Le projet de loi prévoit de plus: a) La saisine par la nouvelle compagnie de tous les droits, intérêts, attributions, pouvoirs, privilèges, biens, actifs, passifs, charges et obligations des deux compagnies fusionnées; 6) Le mode d'enregistrement au nom de la nouvelle compagnie des biens immobiliers dont elle sera saisie en conséquence de la fusion: c) Les droits, privilèges et restrictions attachés aux actions classe « A » et classe « B » et le mode et les conditions d'émission desdites actions de la nouvelle compagnie en échange des actions des deux compagnies fusionnées; d) La composition du Conseil d'administration de la nouvelle compagnie et ses pouvoirs jusqu'à la convocation des premières assemblées des actionnaires après l'entrée en vigueur de la loi; e) L'abrogation du chapitre 137 des lois de 1966/67 et des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires émises en faveur de « FIDUCIE PRET ET REVENU » conformément à la Loi des compagnies de fidéicommis; /) Et d'autres dispositions connexes.Québec, ce 12ième jour de novembre 1973.Les procureurs des requérantes, Jacques Flynn, c.r.54685-46-4-0 André Verce, c.r.FIDUCIE PRET ET REVENU PRET ET REVENUE LTEE Notice is given that \"FIDUCIE PRET ET REVENU\" and \"PRET ET REVENU r.TRV\", onr-cr lions havï\"\"\" t.1-!- \u2022 s offices :n the City of Québec, will file with the Secretariate of Committee of the Nationa, Asse- bly of Québec, a bill amalgamating said compa-ni-sim _ .cor oration under the name of \"FIDUCIE PRET ET Rri v o i,.rc.c .ana \"SAVINGS AND INVESTMENT TRUST\" in English, with an authorized capital of $6.000,000 divided in 300,000 Class \"A\" shares having a par value of $10 and 300,000 Class \"B\" shares having a par value of $10, in order to carry on generally all the operations of a trust company, with all the powers described in the Trust Companies Act.(R.S.Q., 1964.Chapter 287) and certain other ancillary poweis.The Bill provides furthermore: (a) The seisin by the new company of all the rights, interests, appropriations, powers, privileges, property, assets, liabilities, charges and obligations of the two amalgamated companies; (6) The form of registration in the name of the new company of the immoveable property of which it shall take possession as a result of the amalgamation ; (c) The rights, privileges and restrictions attaching to the Class \"A\" and Class \"B\" shares and the terms and conditions for the issuing of said shares of the new company in exchange of the shares of the two amalgamated companies: (d) The constitution of the Board of Directors of the new company and its powers until the shareholders are convened for the first meetings following the coming into force of the Act; (e) The repeal of Chapter 137 of the Statutes of 1966/67 and of the letters patent and supplementary letters patent issued in behalf of \"FIDUCIE PRET ET REVENU\" under the Trust Companies Act; (/) And other related provisions.Québec, this 12th day of November, 1973.Jacques Flynn.q.c, André Verge, q.c, 54685-46-4 Attorneys for Applicant. 7044 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November U, 1973, Vol.105, No.17 Compagnie Trust Royal La compagnie Trust Royal, en sa qualité d'unique exécutrice et fiduciaire de la succession de feu Frank Carrel aux termes du testament de ce dernier, avec l'assentiment de l'Université Queen's, de Kingston, Ontario, et du recteur de l'Université Laval, demandera à l'Assemblée nationale, au cours de sa prochaine session, d'adopter une loi permettant, nonobstant ledit testament, de remplacer par l'unique exigence d'un domicile québécois les critères religieux, ethniques et régionaux que le testateur a imposés pour l'octroi de bourses de l'Université Queen's à des étudiants du Québec.Québec, le 30 octobre 1973.Les procureurs de la pétitionnaire, Létourneau, Stein, Marseille, 54665-46-4-0 Delisle & Larue.HUBERT LAKE UNGAVA NICKEL MINES LIMITED (No personal liability) Messieurs Arthur Fortens, Norman W.Lamport et Fred Munger donnent avis qu'ils déposent au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale du Québec un projet de loi avant pour objet de révoquer la dissolution de la charte de « HUBERT LAKE UNGAVA NICKEL MINES LIMITED » (no personal liability).Québec, le 19 novembre 1973.Les procureurs des intéressés, Philippon, Garneau, Tourigny, 54859-47-4-o & Associés.Cité de Sherbrooke Avis est donné que la Cité de Sherbrooke déposera au Secrétariat des commissions de l'Assemblée nationale un projet de loi refondant sa charte et plus particulièrement: 1° Changeant son nom en celui de « Ville de Sherbrooke » ; 2° L'autorisant à acquérir, construire des immeubles devant servir en totalité ou en partie à des fins municipales, vendre ou louer ces immeubles avec l'approbation de la Commission municipale du Québec, et à ces fins, contracter des emprunts et conclure des ententes avec des tiers sujet à des réserves quant à la participation de la ville dans les déficits; 3° L'autorisant à pourvoir elle-même ou par l'intermédiaire d'une corporation sans but lucratif à l'exploitation de centres de loisirs et de plein air dans un rayon de vingt milles en dehors de ses limites et à cette fin exercer tous les pouvoirs conférés par la Loi des cités et villes; 4° L'autorisant à détenir des permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout lieu public municipal; 5° Décrivant ses limites territoriales et divisant la ville en quatre quartiers connus sous les noms de quartiers nord, est, ouest et centre; Royal Trust Company The Royal Trust Company, in its capacity as sole executor and trustee of the estate of the late Frank Carrel under his will, with the consent of Queen's University, Kingston, Ontario, and the Rector of Laval University, will apply to the National Assembly, at its next session, for an act that will permit, notwithstanding the said will, to substitute the sole requirement of Province of Quebec domicile for the religious, ethnic and regional criteria imposed by the testator for the grant of scholarships by Queen's University to students from the Province of Québec.Québec, October 30, 1973.Létourneau, Stein, Marseille, Delisle & Larue, 54665-46-4-0 Sollicitors for the petitioner.HUBERT LAKE UNGAVA NICKEL MINES LIMITED (No personal liability) Notice is given that Arthur Fortens, Norman W.Lamport et Fred Munger are filing with the Secretariat of the Commissions of the National Assembly of the Province of Québec a bill in order to obtain the revocation of the dissolution of \"HUBERT LAKE UNGAVA NICKEL MINES LIMITED\" (no personal liability).Québec, November 19, 1973.Philippon, Garneau, Tourigny & Associates, 54859-47-4-0 Attorneys for the Petitioners.City of Sherbrooke Notice is given that the City of Sherbrooke (Cité de Sherbrooke) will file with the Secretariat of Committees of the National Assembly a bill revising its charter, and, more specifically: 1.Changing its French name to that of Ville de Sherbrooke ; 2.Authorizing it to acquire, and construct buildings to be used wholly or in part for municipal purposes, to sell or to lease said buildings with the approval of the Québec Municipal Commission, and, for such purposes, to contract loans and conclude agreements with third parties, subject to reservations as to the City's participation in the deficits; 3.Authorizing it to provide, on its own or through a non-profit corporation, for the operation of recreational and outdoor centres within a radius of twenty miles outside its limits and for this purpose to exercise all the powers conferred by the Cities and Towns Act; 4.Authorizing it to hold licences for the sale of alcoholic beverages in any public municipal establishment; 5.Describing its territorial limits and dividing the City into four wards known under the names of North, East, West and Centre Wards; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 31 novembre 1973, 105' année, n° 17 7045 6° Décrétant que le conseil est composé du maire, de trois conseillers pour chacun des quartiers nord, ouest et est et d'un conseiller pour le quartier centre: 7° Autorisant le conseil à nommer des comités d'études; 8° Décrétant le mode de publication d'un avis public donné par insertion dans les journaux sans formalité d'affichage; 9° L'autorisant à établir un tarif d'honoraires exigibles pour l'émission des certificats d'approbation des permis de construction; 10° L'autorisant à réglementer, les panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou à être érigés et prévoir l'enlèvement des enseignes non conformes aux règlements; 11° Décrétant que le coût des travaux encouru par la Cité pour faire respecter ses règlements de construction et de zonage constitue une créance privilégiée assimilable aux taxes foncières; 12° L'autorisant à réglementer l'installation dc clôtures à neige; 13° L'autorisant à réglementer et prohiber la garde île certains animaux: 14° L'autorisant à établir les endroits où peuvent être situés des chantiers de matériaux de construction, en réglementer la hauteur et procéder à leur enlèvement lorsqu'ils constituent un danger; 15 L'autorisant à réglementer ou prohiber la vente, l'entreposage et l'usage des pièces pyrotechniques; 16 L'autorisant à réglementer la vitesse et l'usage d'embarcations à moteur sur les eaux situées à l'intérieur dc ses limites et à prescrire toute autre mesure jugée utile pour la sécurité publique; 17° L'autorisant à décréter des travaux de construction, d'amélioration sur le domaine public et plus spécifiquement, la construction de maiis, à sa charge ou à la charge des contribuables de partie ou de toute la ville; 18° L'autorisant, dans le cas de mails couverts, à obliger les propriétaires y attenants à se munir d'un système de protection contre les incendies; 19° L'autorisant à réglementer pour obliger les propriétaires de terrains situés en bordure d'une rue à construire et à entretenir des murs de soutènement, les construire et les entretenir elle-même, moitié à sa charge et moitié à la charge des propriétaires de la rue concernée; L'autorisant à répartir le coût de construction et d'entretien soit en raison dc l'étendue en front ou dc leur évaluation; 20° L'autorisant à approprier les revenus des terrains de stationnement au remboursement des emprunts contractés pour l'établissement de ces terrains; 21° L'autorisant à confier à toute personne, société ou corporation sans but lucratif, l'administration et la gestion de ses terrains de stationnement; 22° L'autorisant à décréter que dans le cas de contravention aux règlements de stationnement, toute personne dont les services sont retenus à cette fin peut remplir un billet d'assignation avec les mêmes pouvoirs conférés aux agents dc police aux termes de l'article 6.Enacting that the Council be composed of the Mayor, of three councillors for each of North, West and East Wards and of one councillor for Centre Ward; 7.Authorizing the Council to appoint study committees; 8.Ordering the form of publication of a public notice given by insertion in newspapers without any posting formalities; 9.Authorizing it to establish a schedule of fees exigible for the issuing of certificates of approval of building permits; 10.Authorizing it to regulate respecting billboards and signs already erected or to he erected and make provision for the removal of signs that do not conform with regulations; 11.Enacting that the cost incurred by the City for works resulting from the enforcement of its building and zoning regulations constitutes a preferential debt classed as property taxes; 12.Authorizing it to regulate respecting the installation of snow-fences; 13.Authorizing it to regulate or prohibit the keeping of certain animals; 14.Authorizing it to determine those places where yards for building material may be located, regulate respecting their height and proceed to their removal when they constitute a hazard; 15.Authorizing it to regulate or prohibit the sale, storage and use of fireworks; 16.Authorizing it to regulate respecting the speed and use of motor boats on waters located within its limits and to prescribe any other measure deemed advisable for public safety; 17.Authorizing it to enact that construction and improvement works be undertaken on the public property and.more specifically, the construction of malls, the costs thereof to be borne by the City or by taxpayers from part or from the whole City; 18.Authorizing it.in the case of covered malls, to oblige proprietors whose property adjoins thereto to provide themselves with a fire protection system; 19.Authorizing it to provide regulations obliging proprietors of lots bordering on a street to construct and maintain retaining walls, to construct and maintain them itself, one half of such costs to be borne by the City, the other half by owners of properties on the street concerned ; Authorizing it to apportion construction and maintenance costs either on the basis of street frontage or of their evaluation; 20.Authorizing it to appropriate the income from parking lots for the reimbursement of loans contracted for the construction of such lots; 21.Authorizing it to entrust the administration and management of its parking lots to any non-profit company, corparation or person; 22.Authorizing it to enact that, in the case of a violation of parking regulations, any person employed for the purpose be authorized to issue a notice of summons with the same powers as those conferred upon police officers under the terms of section 426 (17) of the 7046 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973.Vol.105, No.17 426 (17) de la Ix)i des cités et villes et encourant les mêmes effets juridiques y mentionnés; 23° L'autorisant à expédier un avis d'infraction ou de rappel, selon le cas, à tout contrevenant aux règlements de circulation et de stationnement et à exiger, en sus de l'amende, une somme n'excédant pas $5.00 pour les frais dc cet avis; 24° L'autorisant à réglementer la vitesse îles véhicules automobiles dans son territoire sujet à affichage lorsque la vitesse excède celle permise par le Code de la route; 25° Lui donnant le privilège exclusif dc vendre de l'électricité dans son territoire et l'autorisant à accorder ce privilège à toute personne: 26° L'autorisant à acquérir et à construire des usines pour la production de l'électricité, à en acheter, en louer ou en vendre dans son territoire ou dans un rayon de trente milles; 27\" L'autorisant à affecter en premier lieu les revenus provenant de la vente dc l'électricité au remboursement des emprunts faits par le service de l'électricité: 28° L'autorisant à vendre ou à louer les réseaux et lignes dc distribution d'énergie électrique sis hors de son territoire à la Commission hydro-électrique de Québec: 29° L'autorisant à conclure tout contrat pour la construction, la propriété et l'usage en commun dc poteaux avec les compagnies de télécommunications; 30° L'autorisant à construire, acquérir, posséder et exploiter un service de transport en commun dans la ville et dans un rayon de dix milles; 31\" L'autorisant à accorder une franchise exclusive pour une période n'excédant pas dix ans pour les services d'un transport en commun dans ses limites et de celles-ci à Lennox ville et retour.Cette franchise n'affecte aucun service de transport par autobus n'ayant que son terminus dans la ville et qui transportent des voyageurs du terminus à l'extérieur de la ville et vice-versa; 32° L'autorisant à fixer le nombre dc membres composant la Commission du fonds dc pension; 33° Décrétant l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sis dans une municipalité voisine et longeant une rue de la ville à acquitter le coût du déneigement de la même manière qui sont tenues les personnes dont les terrains sont situés dans la ville, celte créance étant privilégiée au même rang que les taxes municipales; décrétant que si le coût de ce service est réparti sur la base de l'évaluation municipale de ces immeubles, leur valeur réelle sert de base pour la répartition; 34° Autorisant à imposer une taxe annuelle sur tout habitant âgé de vingt et un ans et plus résidant dans la ville depuis six mois et ne payant aucune autre taxe municipale; 35° L'autorisant à décréter par avis dc motion et résolution l'exécution de travaux permanents dc réfection et de construction de rues, trottoirs, chaînes de rues, d'amélioration et réparation du réseau électrique, de signalisation routière, d'égout et d'aqueduc, l'achat du matériel requis et des emprunts temporaires pour dé- Cities and Towns Act and said notice to have the legal effects mentioned in said Act; 23.Authorizing it to send a notice of violation or of reminder, as the case may be, to any party contravening traffic and parking regulations and to demand, in addition to the fine, an amount not exceeding $5 to cover the cost of such notice; 24.Authorizing it to regulate respecting the speed of motor vehicles within its territory, subject to the posting of signs when the speed exceeds the speed permitted by the Highway Code; 25.Granting it the exclusive privilege of selling electricity within its territory and authorizing it to grant this privilege to any person; 26.Authorizing it to acquire and construct plants for the production of electricity, and to purchase, lease or sell same within its territory or within a radius of thirty miles; 27.Authorizing it to appropriate the income deriving from the sale of electricity first of all for the reimbursement of loans contracted by the electricity department; 28.Authorizing it to sell or to lease to the Québec Hydro-Electric Commission the electric power supply-networks and lines located outside its territory; 29.Authorizing it to enter into any agreement for construction purposes, for the ownership and the common use of posta with the telecommunication companies; 30.Authorizing it to build, acquire, own and operate a public transportation service in the City and within a ten-mile radius; 31.Authorizing it to grant an exclusive franchise for a period not exceeding ten years for public transportation services within its limits and thence to Len-noxville and return.This franchise does not affect any transportation service by bus having only its terminal in the City and carrying passengers outside the City from the terminal and vice-versa; 32.Authorizing it to fix the number of members for the Pension Fund Commission; 33.Enacting the obligation for the owner or the occupant of a property lying and situate in a neighbouring municipality and bordering on a street of the City to bear the cost of snow removal in the same manner as the persons whose property are located in the City are obligated it; this debt being preferential on the same basis as municipal taxes; enacting that if the cost of this service is distributed on the basis of the municipal evaluation of those immoveables, their real value is used as the basis for the distribution; 34.Authorizing it to impose a yearly tax on any inhabitant ageil twenty-one years or over who has been residing in the City for six months and who does not pay for any other municipal tax; 35.Authorizing it to order by notice of motion and resolution the performance of permanent works for repairing and building streets, sidewalks, and curbs, for improving and repairing the electric network, the system of road signs, sewers and waterworks, the purchase of the required equipment and temporary GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 94 novembre 1973, 105' année, n' 47 7047 frayer le coût de ces travaux pourvu que la somme n'excède pas $10,000,000 et ce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des propriétaires obligés mais avec les seules approbations du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale de Québec et pour décréter par règlement un emprunt à long terme au moyen d'émission d'obligations pour rembourser en tout ou en partie les emprunts temporaires; avant qu'ils n'atteignent la somme de $10,000.000 ce règlement ne requérant que les seules approbations du ministre des affaires municipales de la Commission municipale du Québec; 36° Décrétant que, sauf dans les cas où la loi permet des emprunts sur billets, tout emprunt doit se faire par voie d'émission d'obligations et pour régir les modalités des signatures qui doivent y être apposées; 37° Décrétant que, dans le cas d'expropriation partielle d'un immeuble par la Cité, celle-ci peut en exproprier ou en acheter de gré la totalité lorsqu'elle estime avantageux de ce faire, en raison des dommages causés; 38° Décrétant comme suffisant la simple énonciation de la loi ou du règlement concernés dans toute action ou plainte portée devant la Cour municipale: 39° Décrétant que tout mandat d'emprisonnement émis par la Cour municipale peut être exécuté dans tout district judiciaire par un constable ou agent de la paix; 40° Décrétant que tout emprisonnement im|.Kjsé par un juge de la Cour municipale puisse être purgé dans la prison commune du district où le mandat d'emprisonnement est exécuté; 41° Autorisant sa commission athlétique à faire des règlements pour sa régie interne, les conditions d'obtention et usages des permis, la préparation, l'organisation et la tenue des spectacles de boxe et de lutte; 42° Autorisant la commission athlétique à percevoir un pourcentage des recettes brutes lors de ces spectacles et décrétant que tout promoteur de boxe et de lutte doit dénoncer à la commission son contrat avec tout commanditaire de radio ou de télévision, afin de percevoir et de retenir les sommes à elle dues; 43° Ratifiant l'acquisition par la ville de Sherbrooke d'une partie du lot 113, maintenant connue comme étant les lots 113-13, 113-14.113-15 et 113-18.aux plan et livre de renvoi officiels du Canton d'Orford, au moyen d'une expropriation dont jugement a été enregistré au Bureau d'enregistrement de Sherbrooke sous le numéro 119714, ainsi que la vente par la ville de Sherbrooke des lots 113-13 et 113-18 auxdits plan et livre de renvoj à I.a Tribune Inc.par acte de vente devant Gaston Sa-vard, notaire, le 24 février 1967 et enregistré au Bureau d'Enregistrement île Sherbrooke sous le numéro 145561; 44° Autorisant la ville à vendre du gravier provenant de ses puits de gravier et de sable; 45° Remplaçant la loi 1 Georges VI, chapitre 105 et ses amendements ainsi que toutes les autres lois antérieures concernant la Cité lesquels seront abrogés, sauf les droits acquis: loans to meat the cost of those works, provided that the amount does not exceed $10,000.000: the foregoing without having to obtain the approval of the obligate owners, but only that of the Minister of Municipal Affairs and of the Québec Municipal Commission and to order by bylaw a long-term loan by issuing bonds in order to reimburse the whole or part of the temporary loans before they reach $10,000,000.said bylaws requiring the sole approval of the Minister of Municipal Affairs and that of the Québec Municipal Commission; 36.Enacting that, except when the law authorizes loans on promissory notes, all loans must be raised by way of bond issues, to establish the terms and conditions of the signatures to be affixed thereon; 37.Enacting that, in case of a partial expropriation of an immoveable by the City, the latter may expropriate or purchase by private contract the whole of said immoveable when it deems advantageous to do so, because of the damage suffered: 38.Enacting that it shall suffice to set forth the act or the bylaw concerned in any suit or claim brought before the Municipal Court: 39.Enacting that any warrant of committal issued by the Municipal Court may be enforced in any judicial district by a constable or peace officer: 40.Enacting that any term of imprisonment imposed by a judge of the Municipal Court may be served in the prison of the district in which the warrant of committal shall be enforced; 41.Authorizing its Athletics Commission to establish bylaws for its internal management, as well as the requirements for obtaining anil using permits, preparing, organizing and holding boxing and wrestling shows; 42.Authorizing the Athletics Commission to collect a percentage of the gross receipts on occasion of said shows and enacting that any wrestling or boxing promoter must give notice to the Commission of his contract with any radio or television sponsors, in order to collect and to retain the amounts due to said Commission ; 43.Ratifying the acquisition by the City, of Sherbrooke of part of lot 113.presently known as lots 113-13.113-14, 113-15 and 113-18, on the official plan and book of reference for the Township of Orford, by means of an expropriation whose judgment has been registered at the Sherbrooke Registry Office under number 119714, as well as the sale by the City of Sherbrooke of lots 113-13 and 113-18 on said official plan and book of reference, to l,a Tribune Inc.by deed of sale before Gaston Savard, notary, on February 24, 1967, and registered at the Sherbrooke Registry Office under number 145561; 44.Authorizing the City to sell gravel from its gravel and sand pits; 45.Replacing Act 1 George VI, Chapter 105 and its amendments as well as all previous acts respecting the City, which shall be repealed to the exclusion of vested rights: 7048 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November OY MARCHAND INDUS-No.05-008727-73A ^ TRIEL LTEE, a body politic > legally incorporated and having a business office at 6615 Park Avenue, in the city and district of Montreal, plaintiff, vs R.DUBOIS & FILS LTEE.a body politic legally incorporated and having a business office at 180 Belleville, in Ste.Mélanie.District of Joliette.defendant, and THE REGISTRAR for the Joliette Registration Division, mis en cause.\"A certain emplacement known and described as being subdivision ten of original lot seventy-six (76-10) on the officiel plan and in the book of reference for the Parish of St.Charles-Borroméc, with a building erected thereon.\" To be sold at the Joliette Registration Division Office, Notre-Dame Street, Joliette, County and District, on TUESDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY, 1973, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Bureau du Shérif, Joliette, le 16 novembre 1973.Le shérif, Christian Roy.54854-0 Chhistian Roy.Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, November 16.1973.54854 7052 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.105, No.47 PONTIAC Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Pontiac ( \\jf HAROLD MICHAEL BELL, du No 5755A LVL.canton de ITsle-des-Allumettes, » P.Q., gréeur, demandeur, versus M.SY L-VESTER O'BRIEN, du canton de l'lsle-des-Allu-mettes.P.Q., défendeur.« Village de Chapeau, les lots numéros 9, 12, 13, 14 et 15 ainsi qu'une partie du lot 16, avec les bâtiments ci-dessus érigés.Sauf et à distraire la partie vendue par le défendeur à Sa Majesté la Reine du chef de la province dc Québec par un acte de vente décrit dans un certain acte exécuté devant le notaire Donat LeGuerrier le 20 janvier 1967 et enregistré le 28 janvier 1967 sous le numéro 79895.Pour être vendus au bureau d'enregistrement de la division de Pontiac, rue John's, Campbell's Bay (Québec), le SEIZIÈME jour du mois de JANVIER 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, M.André Laçasse.Ce 16 novembre 1973.54824 RICHELIEU Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec District de Montréal Cour provinciale.I \"D OBERT BEAUDET.partie de-No 288 234.\\ manderesse, vs JOHN BAR-l RON alias PAUL WALL 192.rang des Soixantes, St-Marc-sur-le-Richelieu, district de Richelieu, partie défenderesse.« Les immeubles de la partie défenderesse au 192 Rang des Soixantes - St-Marc-sur-le-Richelieu, district de Richelieu.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Verchères, à Verchères, district de Richelieu, P.Q.VENDREDI, le VINGT-HUITIÈME jour de DÉCEMBRE, 1973, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Le shérif Ad Hoc.Palais de Justice, Mercier Grégoire.Sorcl.le 19 novembre 1973.54863-o PONTIAC Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Pontiac ( Vyf HAROLD MICHAEL BELL, of the N'o.5755a LVI.Township of Allumette Island.I P.Q., Rigger, plaintiff, versus M.SYLVESTER O'BRIEN, of the Township of Allumette Island, P.Q., defendant.\"Village of Chapeau, lots numbers 9, 12, 13, 14 and 15 and part of lot 16, together with buildings thereupon erected.Save and except the part thereof sold by the defendant to Her Majesty the Queen in the rights of the Province of Québec by deed as described in a certain deed passed before Donat LeGuerrier on the 20th of January 1967 and registered on the 28th of January 1967 under number 79895.To be sold at the Pontiac Division Registry Office, John's Street, Campbell's Bay, Que., on the SIXTEENTH day of JANUARY.1974, at TEN o'clock in the forenoon.M.André Laçasse, Sheriff's Office, Sheriff.November 16, 1973.54824-o RICHELIEU Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec District of Montreal Provincial Court.I T> OBERT BEAUDET plaintiff, No.288 234.\\ -CV vs JOHN BARRON, alias I PAUL WALL.192 Rang des Soixantes, St.Marc-sur-Ie-Richclieu, District of Richelieu, defendant.\"The immoveables belonging to the defendant located at 192 Rang des Soixantes, St.Marc-sur-le-Richelieu.District of Richelieu.\" To be sold at the Verchères Registration Division Office, in Verchères, District of Richelieu.P.Q.on FRIDAY, the TWENTY-EIGHTH dav of DECEMBER.1973.at TEN THIRTY o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Mercier Grégoire.Court House.Sheriff Ad Hoc.Sorel.November 19, 1973.54863 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 novembre 1973, 105' année.11° ',7 7U53 Errata Errata Paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel Dans l'avis de soumission publié dans l'édition numéro 46 du 17 novembre 1973, page 6SS7, avant-dernier paragraphe, dernière ligne, et page 6SSS, 2ième paragraphe, 1ère ligne, la date (l'échéance aurait dû se lire: « 1er janvier 1994 » au lieu de: « (1er janvier 1974) -.54696-0 Erratum Dans l'avis de dissolution éventuelle de corporations publié dans l'édition 44 du 3 novembre 1973.à la page 6380.27ièmc ligne, nous aurions dû lire: « MONTE CASSINO SOCIAL CLUB INC.\u2022 au lieu de: « MONTE CASINO SOCIAL CLUB INC.54695-0 Parish of St Pierre-de-Sorel In the notice of requests for tenders published in issue number 46, dated November 17.1973, the date of maturity in the last line of the second last paragraph of page 6887 and in the first line of the second paragraph of page 6888, should have read: \"January 1, 1994\" instead of \"January 1, 1974\".54696 Erratum In the Notice of Eventual Dissolution of Corporations published in issue number 44, dated November 3.1973.on page 6380.27 th line, the name should have read: \".MONTE CASSINO SOCIAL CLUB INC.\" instead of: \"MONTE CASINO SOCIAL CLUB INC.\" 54695 Erratum Erratum Dans l'avis de dissolution éventuelle de corporations, publié dans l'édition numéro 45 du 10 novembre 1973.nous aurions dû lire: In the Notice of Eventual Dissolution of Corporations, published in issue number 45.dated November 10.1973.the following names should have read: \"BOURQCE AUTOMOTIVE INC.\" au lieu de I instead o/: \"BOl'RQt'E ACTOMOBILE INC.\" ¦'COLONAA^EVELOI^IENT (ST.FRANÇOIS) LTD.\" au lieu de I instead of: \"COLONIA DEVELOPMENT (ST.KRAN-\"DRESSCO INC.\" :iu lieu to:instead of: \"DKESSO INC.\" \"ESTONIAN BAKERV INC.\" :iu lieu de instead of: \"ESTONIAM BAKERY INC\" 54695-0 Erratum Dans l'avis de lettres patentes annulées publié dans l'édition 44 du 3 novembre 1973.lOième ligne, nous aurions dû lire: - HOW MARK CORP.LTD.au lieu de: « HOWARK CORP.LTD.54695-0 Erratum In the notice of letters Patent Annulled published in issue number 44.dated November 3.1973, in the 10th line, the correct name should have been: \"HOW-MARK CORP.LTD.\" instea.l of: \"HOWARK CORP.LTD.\".54695 7054 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November ta, 1973, Vol.105, No.i7 INDEX No 47 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ARRÊTÉ EN CONSEIL ORDER IX COUNCIL 4071-73\u2014Saiilt-Suint-l.ouis, es.(Ancien nom: municipalité scolaire du Centre-Sud de Montréal).6988 4071-73\u2014Sault-Saint-Louis, s.b.(Former name: School Municipality oj Centre-Sud de Montreal).6988 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Alliance sécurité et investigation limitée.«noe Alliance Security and Investigation Limited.«oo?Estate of Mounir Cliamoun [Benefit of Inventory).cnci Estate of Réjean Landry {Benefit of Inventory).Estate of Yvon Perreault (Benefit of Inventory) ._ .6984 Montréal, villc-city (Rachat d'obligations-Redemption of bonds) No 107.Montréal, villc-city (Radial d'obligalioits-Rcdemption of bonds) No 108.6986 Succession Mounir Chamoun (Bénéfice d'inventaire).Succession Réjean Landry (Bénéfice d'inventaire).6984 Succession Yvon Perreault (Bénéfice d'inventaire).698^ CHANGEMENT DE NOM - Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Bernier.Joseph Claude Jean.6992 Granat.Samuel .6992 Maguire.Joseph Ronald.6992 Maguire, Joseph Thomas.6992 Mazin, Ruben Robert.6992 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: .1 ppl ications: Beck.Stephen (Istvan).6990 Bourgea.Joseph-Albert-Yvon.6989 Cauchon.Euclide Cvrille.6990 Clérin.David André.6990 Clérin.Lucien Roland.6991 Desbiens.Lucine.6989 Jacques, Jean-Paul.6990 Katz, Barry.6989 Lafond.Nelson.6989 Lengyel.Gustave .6991 Mazer.Irving.6989 Paradis.Flore.6991 Skoularinos.Demitrios.6991 Smith.Jack Albert.6990 CAISSES D'ÉPARGNE SAVIXGS AND COMMISSION COMMISSION ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS _ , \u201e _ .Commission Québec transport Caisse d économie Notre-Dame du Sacre- des transports du Québec Commission ( oeurt redit Union (La) (Liquidalion-il ind- ing-Up).7025 Avis d'introduction de requêtes.6969 Caisse Populaire Charles Lemoyne ( La) (.WW.Notice of submission of application.6969 ten.).7026 Caisse Populaire St-Valère (La) (Nom-Name ch.) .7025 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 34 novembre 1973.105' année, n° 17 7055 Places d'affaires Places of Business dans la province: in Ihc Province: Aldershot Carry-All Services Ltd.6982 Ambler-Courtney Ltd.6982 Bradai Holdings Inc .6982 Brown (.lack).6981 Hurdman Bros.Ltd.6983 Liquid Cargo Lines Limited.6983 Lou\"s Transport Co.Limited.6983 M.G.M.Transport Corporation.6981 Nesel Fast Freight Inc.6981 New Woodbine Transport (196N) Ltd.6982 Pcplow Transport Limited.6983 Selleck (George Harold).6983 Slack Transport Ltd.6982 Tank Truck Transport Limited.6983 Traverse M.S.S.Ltée.6982 COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL ÉTRANGÈRES COMPANIES Perm is: Licenses: Arkansas-Best Freight System, Inc.7029 Atlantic Resource Consultants Limited .7029 El Paso Mining anil Milling ( ompany.7030 Kenn Development Corporation .7030 MSI Data Corporation 7030 COMPAGNIES \u2014 COMPANIES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Allaire & Hawkins Ltd 6965 Aubin & St-Pierre (l)riimmond) Inc.6965 Aubin & St-Pierre (Ganby) Inc ____ 6965 Bowen (Murray) Holdings Ltd .6965 Capri-Colgcr Ltd .6965 Chez Alexandra Inc.6965 Club du Nord Inc.(Le).6965 Consol Investments ( 'orp.6965 Cornell Investment Corp.6965 Domaine du Pécheur Inc .6965 Dontigny & Cyr Inc.6965 Dufresne et Racine Inc .6965 Dunleigh Men's Wear Inc.6965 Entreprises Lac Bowkcr Inc.6965 Estate Hon.John Hearn Inc .6965 Fleur de Lys Stamp Vending Services Inc 6965 Gagné, Lévcsque, Oiiellet & Pelletier Inc 6965 Houle (J.A.) Inc .6965 Lawpa Ltd.6965 Lomanco Investments Limited.6965 Lumber (M.F.) Ltd .6965 Margolis (Jack) Holdings Ltd.6965 Matériel d'enseignement Mclntyre Ltée (Le).6965 Mclntyre Educational Materials Ltd.6965 Michael-John Enterprises Ltd .6966 Norman's Auto Repair Ltd.6966 Percar Investments l.td.6966 Placements Percar Ltée .6966 Primo Gaz-Bar Inc.6966 Quartet Investments Ltd .6966 Rodair Inc.6966 Rouyn Improvements Limited .6966 Services automatiques de timbres Fleur de Lysine.(Les).6965 Société de placements Dcntura Inc.(La).6966 Telmar Construction Inc .6966 Tremblay (Willie) Inc.6966 Tubman Holding Corp.Ltd.6966 Voyageur Abitibi Inc .6966 Weinberg (Jennie) Investments Ltd.6966 Avis d'annulation Notice of annulment de chartes of Charters (2° avis) (2nd notice) Equipements du Nord Ltée .6967 Labelle (A) Bar-B-Q Inc.6967 North Equipments Ltd 6967 Changement de nom Change of name Associés de Mandelker Ltée (Les).6967 Cazelais et Lavoie Inc.6966 Compagnie de Vêtements J.G.Ltée ( Lui 6966 Confection St-Ours Inc.6966 Corporation d'Investissements Mi.ntrow (La).6966 Diroca Inc .6966 Dynamic Circulation Inc .6967 Entreprises de Pipe-Line Universel Ltée.6966 Imprimerie St-Eustache lue 6966 Investissements Lucienne Gagnc.ii (1973) Inc.6966 Mandelker Associates Ltd 6967 Messageries Dynamiques Inc.(Les) 6967 Montrow Investment Corporation.6966 Placements R.Desjardins Inc.( Les) 6967 Universal Pipe Enterprises Ltd 6966 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter A.A.French Publications Inc .7004 Aide à l'éducftion de l'école Supérieure de Granby Inc.(I/) .7004 Aima r ltée.7010 Alouette Automobile inc .7005 Bcaudct (.1.I.I Inc .- 7011 Begin Slate Inc.7005 Bouesn&rd (Jacques) Ltd 7011 Centre de traitement « L'Escale inc.7009 Cie de Construction St-Gcorgcs de Sherbrooke Inc.(La) .7004 Cogan (.1.) Inc 7010 Deconilcx Enterprises Inc.7005 District Finance Corporation Limited.7011 Dominion Sj nthetics Ltd 7004 Edifice Boulin inc .7012 Entreprises Dccuretcx inc.(Les) 7005 Forme Tbihi'.udcaii limitée 7010 4492 Sherbrooke Street West (Inc.! ____ 7009 G S Investments Ltd 7006 Hatch & Company Limited 7006 7056 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, Xtmmber J4.1973, Vol.105.So.17 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter (tuile) (continued) Hôpital général de Joliette.iOIO Iiiiini'iililes Figaro Inc.(Les).[nterbancorp (Mtl) l.tL novembre 1973.105' année, n' 47 7059 Sièges sociaux (suite) Head Offices (continued) Jashkamo Cleaners Inc.6999 Laboratoire Pentagone ltée.7000 Lauzon Drive Yourself Inc.6999 Leigh Investments (Montreal) Limited.7000 Lizmax Holding Corp.6992 Louis Foods Ltd.6993 Maison Jérôme inc.7000 Maisons Familiales d'You ville inc.(Les) .7001 Nettoyeurs Jashkamo inc.6999 Nordore Mining Co.Ltd.7002 Pentagone Laboratory Ltd.7000 I'hilmar Cooling Inc.7001 Piedmont Equipment Ltd.6996 Placements Innocan limitée (Les) .6999 Québec School Photography Services Inc.7001 Réfrigération Philmar Inc.7001 Restaurant Délices Iiar-B inc.6994 Restaurants & Motels Inter-Cité inc.7003 Robe du Québec (1973) Inc.(La).7002 Services alimentaires Intercité inc.(Les) .6999 Services île Photographie Scolaire du Québec inc.(Les) .7001 Société Canadienne Française de Radiologie Inc.(La).7000 Stangard Inc.7002 Svstèmes d'ordinateurs Buydal inc.6995 Taxi Villani ltée.7002 Curatelle publique Successions vacantes: Public Curatorship l'acant Estate*: Bonami.Pierre.7015 Cayer, Huguette .7016 Lapointe, René.7016 APPLICATION TO LEGISLATURE DEMANDES A LA LÉGISLATURE Club de Golf Le Portage inc.7042 Compagnie Trust Royal.7044 Église Béthanie.7043 Fiducie Prêt et Revenu.7043 Hubert Lake Ungava Nickel Mines Limited 7044 Prêt et Revenu ltée.7043 Royal Trust Company.7043 Sherbrooke, cité-city.7044 Député élu Member Elected Sainte-Marie: Malépart (Jean-Claude) 7003 LIQUIDATION DES COMPAGNIES Loi de la WINDING-UP ACT Caisse d'économie Notre-Dame du Sacré-Coeur Crédit Union (La).7025 MINISTÈRES Affaires municipales Rivière-Pigou, inun.(/./'.) DEPARTMENTS Municipal Affairs .7016 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Rivière-du-Loup (Demande-Request).6988 Sault-St.Louis, c.s.-s.b.(Nom-Name ch.).6988 Financial Institutions Companies and Cooperatives Insurance: Institutions financières compagnies et coopératives Assurances: Progressive, compagnie d'assurance (La) (An-nul.).7028 Progressive, compagnie d'assurance (La) (Demande de remise des valeurs).7028 Progressive Insurance Company (The) (An-nul) .7028 Progressive.Insurance Company (The) (Application for return of securities).7028 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolut ion of Corporations.A.R.V.Inc.6935 Abbott Realties Ltd.6935 Académie de musique de Ville de Laval.6935 Agences A.L.du Québec inc.6935 Agences Empire Compagnie limitée (Les) 6935 Alarie (Ravmond).6935 Albatros Gold Mines Ltd.6935 Alboro Inc.6935 Albrian Investments Limited.6935 Al-Ca Industries Ltd.6935 Alca Upholstering and Sadding Inc.6935 Aldo & Rosy ltée.6935 Alcman Corp.6935 Alexandrex inc.6935 Allan! (J.M.; construction ltée.6935 American Autorama Ltd.6935 Ameublements Maisonneuve inc.6935 Anclo Amusements Inc.6935 Antique Fair Inc.6935 Anton & Bolduc inc.6935 Aristotalis Valaoritis Lefkadian Society of Montreal .6935 Arrelo Inc.6935 Arrin Curley ltée.6935 Arroseurs Blainvillc inc.(Les).6936 Arrow Products Canada Ltd.6936 Artapis inc.6936 Artec International Inc.6936 Artefact Inc.6936 Artistic Novelty Mfg.Co.Ltd.6936 Arton Enterprises Ltd.6936 Arts Gravure Inc.6936 Arwepiwin Fish & Game Club.6936 Asber ( 'orp.6936 Asbcs-Dusso Inc.6936 70(10 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November Si, 1973, Vol.105, No.47 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Asbestos Boulevard Auto Limited.6936 Ashley's (St.James) Ltd.6936 Asphalte Gilles Boisvcrt inc.(L').6936 Asphalte Rive Sud inc.6936 Assembly Theatre (The).6936 Associated Packers Limited.6936 Association des constructeurs d'avions expérimentaux de Québec inc.6936 Association des entrepreneurs en posage de tapis du Québec inc.(L').6936 Association federative des étudiants de l'Université dc Sherbrooke (A.F.E.U.S.).6936 Association G.T.I.6936 Association des parents d'enfants aphasiques inc.(L').6936 Association parents-maîtres des écoles Emard- Girard-Langlois.inc.6936 Association des prothésistes & orthotistes du Québec.6936 Association des résidents de Place Belle-rive (L').6936 Association de Thetford Mines pour les enfants arriérés (L\").6936 Association des vendeurs de pièces d'autos usagées (AVPAU) inc.6936 Assurances Létourneau inc.6936 Aster Investment Co.Ltd.6936 Asteria Café inc.6936 Astir Book Store Inc.6936 Astor Land Inc.6936 Astoria Garage (1968) Ltd.6937 Atacama Industries Limited.6937 Atelier d'art et vitraux Pierre Osterrath inc.6937 Atelier de chorégraphie canadienne inc.(L') 6937 Ateliers d'art de France ltée.6937 Ateliers St-Marc limitée (Les).69o7 Ateliers de vitraux d'art ltée.6937 Athenian Motion Pictures Ltd.6937 Atlantis Enterprises Ltd.6937 Atlantis Fish Market Inc.6937 Atlas Car Rental Inc.6937 Atlas Furniture Sales Inc.6937 Atlas Lumber Co.Ltd.6937 Atomic Cleaners & Distributors Ltd.6937 Atwater Auto Body Inc.6937 Au Caprice Bar-B.Q.inc.6937 Auberge St-Jean Baptiste inc.6937 Audart Publishing Corp.6937 Auto (Holding) Ltée-Ltd.6937 Auto Motion Speed Shop Inc.6937 Autobus de l'Ouest inc.(Les).6937 Autobus de la Rive Sud ltée (Les).6937 Autodrome Trois-Rivières ltée.6937 Automobiles Manie inc.(Les).6937 Automotive Investment Corporation.6937 Autoski Distribution Inc.6937 Auto-Vente St-Michcl inc.6937 Avec Inc.6937 Aven Inc.6937 A very ltée.6937 Aviron Auto Leasing Corp.6937 Avion (Georges) Clothing Co.Ltd.6937 Avrum Investments Inc.6937 Aztec Iron Corporation.6937 B.& B.Holdings & Real Estate Inc.6938 B.B.Taxi Ltd.6938 B B V Construction Inc.6938 BCD Inc.6938 B.Comms.Inc.6938 B D R Construction Inc.6938 B.R.L.Investment Corporation Ltd.6938 B.S.L.Design Ltd.6938 Bamco Industries Ltd.6938 Batimat ltée.6938 Bayrut Outfitting Inc.6938 Beacon Mining Company Limited.6938 Bear Automotive Safety Service Centre Limited.6938 Bearon Enterprises Inc.6938 Beauce Excavation Inc.6938 Bélanger (J.) Courtiers d'Assurances inc.6938 Bertrand, Bouchard.Viau inc.- .0936 Bibeau (Georges Omer) inc.6938 Boston Bay Mines Limited.6938 Boulanger (Marc) Assurance inc.6938 Boulet Auto Electric Inc.6938 Bourque Automotive Inc.(Erratum).7053 C.B.T.Realties Inc.6938 C.& C.Construction Inc.6938 C.K.C.M.Holdings Limited.6938 C.J.R.Mining Limited.6938 C.& L.Lumber Inc.6938 C.& M Drvwall Inc.6938 Café El Paso (1966) ltée.6938 Camp Bnai Brith inc.6938 Canadian Athletic Supplies Ltd.6938 Caron (B.C.) inc.6938 Cavanal Limited.6938 Cavbridge Resources Ltd.6938 Ceàsar's Palace (1969) Inc.6938 Cadre Constructions Inc.6938 Centennial Automatic Vending Co.Ltd.6939 Central Asbestos Mines Ltd.6939 Centre d'accueil pour alcooliques et autres taxiconames tie St-Eustache inc.6939 Centre aquatique régional de Trois-Rivières Inc.6939 Centre d'art R.U.inc.(Le) ¦ -.6939 Centre d'estrologic zodiaque inc.6939 Centre d'équipement de bureau O.F.C.inc.6939 Centre musical et culturel de Chomedey.6939 Centre récréatif de St-Pierre inc.6939 Chalets Basso inc.(Les).6939 Chalifour & Frères limitée.6939 Chalifoux (J.M.) ltée.6939 Charbonneau (Edgar) (Bonaventure) inc.6939 Chart Bay Explorations Limited.6939 Chauveau Arts & Traditions Inc.6939 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Si novembre 1973, 105' année, n\" 47 7061 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Chez Clémence inc.6939 Chez Fada Inc.6939 Chomedey Go-Kart Inc.6939 Cie de gestion St-Alexandre inc.6939 Cie Nationale d'aspirateurs ltée.6939 Cie de placements l'Emérillon limitée (La;.6939 Cities and Town Suppliers Limited.6939 Civic Land and Development Corp.6939 Clairoux (Gilles) inc.6939 Clan, café-étudiant (Le).6939 Clabet (Eugène) inc.6939 Cleveland Enterprises Inc.6939 Cliche (Patrick) inc.6939 Cliff (Rock) Hotel Inc.6939 Cloe Corporation.6939 Cloutier (Yves) inc.6939 Clover Leaf Land Corporation.6939 Clover Valley Developments Inc.6939 Club d'astronomie de Drummondville inc.6940 Club auto-neige de l'Avenir inc.6940 Club auto-neige Champlain inc.6939 Club auto-neige Pont-Rouge inc.6940 Club de Base-Ball Concorde Laval.6940 Club de C.& P.Corbeau.6940 Club de chasse et de pêche du Lac Ha Ha inc 6940 Club de chasse et pêche Mont-Carmel (Le).6940 Club de chasse Soumandc.6940 Club des chutes de Charette inc.6940 Club de Curling Jacques-Cartier (Le).6940 Club de golf Les Arpents Verts inc.6940 Club de hockey Montmagny inc.6940 Club Lions Clermont-La-Malbaie-Pointc-au- Pic (Murray Bay) inc.6940 ClubMaskimo.6940 Club moto-neige Neuville inc.6940 Club nautique de l'île Goyer inc.6940 Club Oasis des aveubles de Sherbrooke inc.6940 Club Optimiste Val Martin inc.6940 Club Quévillon inc.(Le).6940 Club de réforme de Montréal.6940 Club social et artistique de Québec inc.(La).6940 Club social les Aventuriers inc.6940 Club social des « Moose » de Port-Alfred inc.(Le).6940 Club social et sportif de l'Avenir inc.6940 Club sportif Alho inc.6940 Club Sportif et champêtre Napierville inc.6940 Club des sports de Port Alfred inc.(Les).6940 Club des Trembles inc.6940 Collision Appraisal Services (Québec) Limited.6940 Colonya Development (St.François) Ltd.(Erratum).7053 Combined Investments Ltd.6940 Comeau Automobile Inc.6940 Compagnie Chomodu inc.(La).6940 Compagnie internationale d'expantion commerciale Itee.6940 Compagnie dc traitement des eaux du Québec (La).6941 Compagnons des métiers d'art inc.(Les).6941 Comptoir agricole de St-EIoi inc.6941 Concordia Express Inc.6941 Constructions et immeubles Bernard Boucher inc.(Les).6941 Constructions Saint-Jean limitée (Les).6941 Corporation des citoyens canadiens d'ascendance française ltée (La).6941 Corporation d'expansion l'Apex inc.(La).6941 Corporation des routiers du Québec inc.6941 Cosmox Corporation Limited.6941 Cova Catering Inc.6941 Créations Claudy inc.(Les).6941 Creative Arts Corporation.6941 Crée Indian Center of Chibougamau.6941 D.B.L.C.Construction Inc.6941 D.B.T.Investment Corporation.6941 D.C.Electric Inc.6941 D.H.pavage d'asphalte inc.6941 Daible (Albert) & Fils inc.6941 Danny's Bar Inc.6941 Dansereau (Alex) & Cie ltée.6941 Decelles Avenue Holdings Ltd.6941 Développements Val-Alain inc.(Les).6941 Distributeurs Automotive Mobile Indépendant inc.6941 Distributions F.C.inc.(Les).6941 Doane & Doane Inc.6941 Domaine du bois de Montréal Ltd.6941 Domiro ltée.6941 Dressco Inc.(Erratum).7053 Dynamique de recherche personnelle du Québec inc.6941 Edmor Knitting Mills Ltd.6941 El Torero Steak House Inc.6941 Elite Enterprises Limited.6941 Elizabeth Low Fund Inc.(The).6941 Elizabeth Realty Ltd.6942 Eliott Investments Inc.6942 Elm Investment Corp.6942 Elmount Development Ltd.6942 Elnor Inc.6942 Elpac Electronics Ltd.6942 Elray Inc.6942 Embassy Leisure Wear Inc.6942 Embla Limited.6942 Emma Gold Mines Limited.6942 Emmar Automobiles Inc.6942 Encee Limited.6742 Engo Realties Inc.6742 En-Ola Explorations Limited.6942 Entreprises Bureau & Chouinard ltée (Les).6942 Entreprises Elmec inc.(Les).6942 Entreprises Gatineau inc.(Les).6742 Entreprises Lecabrie ltée (Les).6942 Entreprises Marcotte inc.(Les).6942 Entreprises Maredo ltée (Les).6942 Entreprises Rosaco ltée (Les).6942 Equipement dc restaurant international inc.6942 QUEBEC OFFICIAI.GAZETTE.November 21.J97S, fol.105.No.17 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Estonian Bakery Inc.(Erratum).7053 Exposal Appraisal Inc.6942 Fashion Girl of Montreal Inc.6942 Fédération île Lawn-Tennis du Québec.6942 Fer artistique inc.6942 Ferland (Noël) & Associés inc.6942 Fermes avicoles unies ltée.6942 Ferronnerie d'art inc.(La).6942 Festival des neiges Laiirentien.6942 Finco incorporée.6942 Flibustiers et batelières de Châteauguav-Cen- tre (Les).6942 Fraser, Graf, Bargetzi Inc.6942 G.M.Enterprises Ltd.6942 Gagnon (Michel) ltée.6942 Garage Alger inc.6943 Garde paroissiale Ste-Famillo inc.(I.a).6943 Gatilabel Inc.6943 Gatineau Backhoe Inc.6943 Gatineau Textile Ltd.6943 Gauthier (G & L) Trans-Sport Inc.6943 Gavin Realty Corp.6943 Gaytime Casuals Inc.6943 Gélinas (Wilson) & Frères inc.6943 Gen-Auto Shippers (Québec) Limited.6943 Gani Inc.6943 Gentilly Road Housing Corp.6943 George General Auto Repairs Inc.6943 Geriden Inc.6943 Gingras (Marc) inc.6943 Gingras, Reid.Gaudreau Inc.6943 Giro construction ltée.6943 Glass and Wall Decor (Montreal) Inc.6943 Goudreau (Al.) Cartage Ltd.6943 (ïrand Prix moto-neige Ste-.Fovite Mont-Tremblant inc.6943 Guilde Astrorama ltée.6943 H.B.D.Enterprises Inc.6943 Habitations Emmanuel limitée (Les).6943 Habitations Louis Frechette Inc.6943 Hand Assembling & Packaging Ltd.6943 Hayes Eastern Truck Sales Co.Ltd.6943 Hellenic Fisheries Ltd.6943 Herb Novick Sales Corp.6943 Home Work Assembling Limited.6943 Hotel St-Maurice incorporée.6943 Hudson Bay Syndicate Inc.(The).6943 Hydra Lube inc.6943 I.I.R.Trading Inc.6943 Immeubles Alepin ltée (Les).6943 Immeubles Banc dc Sable inc.(Les).6943 Immeubles Baslor inc.(Les).6944 Immeubles du bassin de Chambly inc.(Les) 6944 Immeubles Germain I'oulin ltée (Le»).6944 Immeubles l,av inc.6944 Immeubles Marcotte ltée (Les) 6944 Imprimerie Marchand Inc.6944 Industries Générales du Québec ltée.6944 Industries Geyser inc.(Les).6944 Industries L.Catien Ltd.(Us).6944 Industries Marco inc.6944 Industries Thermo ltée (Us).6944 Instant Copy Centres Inc.6944 Institut des architectes paysagistes de Québec 6944 Institut des arts de St-Féli'cien (L').6944 International Land Investments Corp.6944 International Reyguy Co.Ltd.6944 Interprovincial Development Co.Ltd.6944 Italswiss Overseas Investment Inc.6944 J.G.Construction Inc.6944 .Fero Enterprises of Canada Limited.6944 Jeune Chambre de l'icrreville (La).6944 Jeune Chambre de St-Alexis-dcs-Monts.6944 Jo-AI Investments Ltd.6944 Jodoin & Jette inc.6944 K.J.Apartments Inc.6944 K.Transport Center Ltd.6944 Kar Enterprises Ltd.6944 Kavser-Roth Industries Limited.6944 Kirako Ltd.6944 K'iwanis Club of Lake St.Louis.6944 Pointe Claire inc.(The).6944 Kot-X-At Incorporated.6944 L.& R.Electronics Inc.6944 Laiterie Gatineau ltée.6944 Lake George Development Inc.6945 Lake Otter Cranium Mines Ltd.6945 Lakeshore Coffee House Association.6945 Lakeshore Construction Company Limited.6945 Lakeshore Garden Supplies Inc.6945 Li'.kevicw Athletic & Social Club of Laval West Inc.6945 Lamontagne Excavation Inc.6945 Lapointe (Gilles) auto location ltée.6945 Larivière Enterprises Ltd.6945 Larochelle (C.) inc.6945 Larouche (Paul-Emile) inc.6945 Laurel Ladies Wear Inc.6945 Laurentian Horsemen Inc.6945 Laurion & Frère inc.6945 l.auvac Inc.6945 Laval Sports Inc.6945 Lave Auto Leclerc Inc.6945 Leblanc (Roger) (Hélicoptère-aviation) ltée 6945 Lee's Fine Foods Ltd.6945 Librairie Bas-Lnurentienne inc.6945 Librairie du Trigone inc.6945 Ligue nationale de baseball junior inc.(La) 6945 Ligue des propriétaires et des contribuables de Ste-Marguerite inc.(La).6945 Limoges (Claude) inc.6945 Lo-Bar Ranch Inc.6945 Locas (Gilles) inc.6945 Loisirs Aubergine inc.6945 Loisirs de Chibougamau inc.(Les).6945 Loisirs de Ste-Cécile-de-Lévrard inc.(Us) 6945 Loisirs Tambour Battant.6945 Longueuil Investment Incorporated.6945 Lowell Realty & Investment Inc.6945 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, :>4 novembre 1073, 105' année, n\" 47 706c Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) M.C.R.Performance Research Inc.6945 M.F.Paint Inc.6945 M.I.C.Distribution Inc.6945 Machinerie Be-AI Inc.6946 Maison du chômeur dc St-Henri inc.(I.a) 6946 Maisonneuve Sportsmen's Social Association Inc.6946 Maîtres Nettoyeurs du Québec inc.(Les).6946 Major Laurent Mines Ltd.6946 Majorettes Les Québécoises (Les).6946 Malcourt Inc.6946 Malda Ltd.6946 Malo Corporate Investments (Que.) Ltd.6946 Maltais & Tremblay Inc.6946 Manara Inc.6946 Manifold Enterprises Inc.6946 Mano Construction Inc.6946 Manoir Montréal (Le).6946 Manoir des Ormes inc.6946 Manoir St-Philippc inc.6946 Mansu Management.6946 (Mantha) P.P.inc.6946 Mantryx Ltd.6946 Maple Enterprises Ltd.6946 .Maple Realty Corp.6946 Marado Construction Inc.6946 Maral Holdings Inc.6946 Maranco limitée.6946 Maraynard ltée.6946 Marbec Steel Corporation.6946 Marbre & Stone Products Limited.6946 Marcel Music Store Inc.6946 Marco Automobiles Inc.6946 Marco Investment Corporation.6946 Massie (Clément) inc.6946 Matthiau (Georges) Auto Center Inc.6946 Menuiserie Biais & Fils inc.6946 Merchants Overseas Corporation.6946 Messageries Laval inc.6946 Metriclab Inc.6946 Metropolitan Hotel Management Inc.6947 Metropolitan Land Co.Ltd.6947 Micro Art Inc.6947 Miracle Art Furniture Creations Inc.6947 Monolea Beach Bungalows Inc.6946 Monsieur Elegant Inc.694; Monte Cassino Social Club Inc.(Erratum).7053 Montreal Mould Makers Limited.6947 Montreal Oil Tank Services Ltd.6947 Montreal Royal Regiment of Canadian Artillery \"Numbers One\" Club.6947 Moorhead Island Lodge Limited.694i Motel l'Emérillon inc.6947 Murray Bay Motor Co.Ltd.(The).6947 Negro Citizenship Association Inc.6947 Nettoyeur Lemay inc.694^ Nettoyeurs Wellington Inc.6947 No Man's Land Youth Center.6947 Norbrite Inc.6947 Norgate Clinical Laboratories Ltd.6947 North East Automotive Industries Ltd.6947 North End Residential Centre Inc.6947 Nouveau Bottin téléphonique italien ltée (Le).6947 Oeuvre des terrains de jeux St-Germain inc.(L').6947 Ogilvy & Mather (Québec) Limited.6947 Old Alfama Restaurant Inc.6947 Old Athens Restaurant Inc.6947 Optica St-Catherine Inc.6947 Orak Service Center Ltd.6947 Pan Canadian Import and Export Inc.6947 Parachutistes du Saguenay Lac-St-Jean inc (Us).6947 Pafé (René) inc.6947 Park-Crest Clothes Inc.6947 Pary (Chantai) inc.6947 Pavage Marcel Morin inc.6947 Pavilion Claude inc.6947 Pellerin (A.) inc.6947 Pern Art Enterprises Inc.6948 Peter & Steve's Snack Bar Inc.6948 Pick (Jan) Tricot Company Ltd.6948 Pincourt Civic League Inc.6948 Pink Shower and Bath Manufacturing Cora- panv Limited.6948 Pipe Beach Club Inc.(La).6948 Piscines Gibraltar inc.6948 Placements La Barre ltée.6948 Placements Vitemont inc.(Les).6948 Placements Ray-Lau inc.6948 Placements Raymond Bre.-.ult ltée (Les).6948 Planneo Sites Inc.6948 Plaza Snack Bar ltée.6948 Pointe-Claire Medical Centre Inc.6948 Pointe-Claire Realty Limited.6948 Poissonnerie du pécheur Jos Paquet inc.(La).6948 Polbcr ltée.6948 Productions L & C inc.(Les).6948 Propriétaires de chalets du lac Cavcn Inc.(Les).694S Publications Hockey Québec inc.(Les).6948 Pvramid Automotive Sales Ltd.6948 Quality Pa I Inc.6948 Quality Pants Inc .6947 Québec Association for the MantHI Retarded 6948 Québec Caulking & Sealants Ltd.6948 Québec Clav Mining Ltd.6948 Quill-O-Rama ltée.6948 R.C.H.Virginie Ltd.6948 R.G.asphalte et construction inc.6948 Ranch Canadians Inc.6948 Rannana Investment Corp.6948 Regent Finance Corporation Limited.6948 Regis antiquaire inc.6948 Rent-All Centre Ltd.6948 Reproductions Antiques Montréal inc.6948 Résidence Ste-Catherine inc.6949 Residences Champs Elysée ltée (Les).6949 Restaurant Manon inc.6949 or, i QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 21, 1973, Vol.10Ô, No.17 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporal ions: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Restaurant Mi-Chemin ltée.6949 Restaurant R.C.inc.(Le).6949 Restaurant St-Gcorges inc.6949 Restaurants Marie-Claire inc.(Us).6949 Robin Cleaners Ltd.6949 Rockv Realties Ltd.6949 Rodier (CH.) cie ltée.6949 Roman Pur Fashions Inc.6949 Roulottes Métropole inc.6949 Roy (Claude) et Frères inc.6949 Ruchers C St-Louis ltée (Us).6949 SB.limitée.6949 St.Cloud Construction liée.6949 St.Sauveur Tennis Club Inc.6949 Ste.Genevieve Gardens Homeowners' Association .6949 Safari Automobile limitée.6949 Sakaris Brothers Fruit Market Inc.6949 Salon Claudette Madore inc.6949 Salon F.lise Inc.6949 Salon international de la mode et de la beauté inc.6949 Salon Laporte inc.6949 Sasseville (Georges) & Fils ltée.6949 Sauvageau (Gérard) construction inc.6949 Seigneurie Galerie d'art (U.).6949 Service auto inc.6949 Service général d'administration M.T.inc.6949 Sevmour Elissen Sales Agencies Ltd.6949 Shamrock Fish Ltd.6949 Siniard Laveuse service inc.6949 Société d'archéologie de Rivière-du-Loup inc.6949 Société des bateaux-mouches inc.(La).6949 Société Con-ad-Gast inc.6960 Société de gestion Clan Savard inc.6950 Société Malbec inc.(La).-.6950 Société urbaine des trans|k>rts rapides inc.6950 Societv of Nursing Assistants of Québec inc.(The).6950 Sodemet Inc.6950 Sofina Inc.6950 Sogemo Inc.6950 Sogerou Inc.6950 Soges Inc.6950 Solem Inc.6950 Sovereign Crude Oil & Asphalt Company Limited .69.50 Smith Realties Inc.6950 Snyder (Garry) Enterprises Corp.6950 Station Service Marcoux inc.095(1 Station Service Roseniont inc.6950 Stirling Investment Corp.6950 Stobers Limited.6950 Storozuk (S.) Transport Ltd.6950 Superior Cleaners Ltd.6950 Suzann- Manufacturing Inc.6950 Swiss Precision Automatic Inc.6950 Style Togs Inc.6950 Taschereau Art Decor Inc.Taverne Rex incorporée.Taverne à la Rivière inc.Taylan Corporation.Techni-Art Inc.Tel-A-Viv Restaurant Inc.Terminal Aviation Services Inc.6950 .6950 .6950 .6950 .6950 .6950 .6950 Thistietown Trading (Québec) ïnc.6950 Town & Country Motorcycle Club.6950 Tremblay & Gervais Inc.6950 Trépanier (Marcel) inc.6950 Trig Limited.6950 Tristar Company Limited.69ol Trudy & Claude's Inc.6951 Turpin (A.R.) ltée.6951 Twin Beaver Mining Company.6951 Union du Livre et des Arts ltée.6951 Union Trunk Sales Corporation.6951 United Aviation Services Limited.6951 United Citizens of Dorval.6951 l'nivrac Inc.6951 Vaillant (Roger) inc.6951 Val Royal Management Inc.6951 Valiant International Trading Corp.6951 Vclpa Construction Inc.6951 Velrac Inc.6951 Viauville Tire Ltd.6951 Vigicoltée .6951 Vitrerie Trans-Québec inc.6951 West End Plaza Inc.6951 West-End Investment Company.6951 Westmount Caterers Inc.6951 White (E.) Incorporated.6951 Woodbridge Beach Club.6951 Zenith Finance Corporation.6951 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: Alberford Sporting Club.6951 Association de chasse et de pèche de St-Augus- tin inc.6951 Association des clubs de chasse et de pêche dc la Mauricie.6951 Belleview-Rand Club Inc.6952 Bier Creek Fish and Game Club.6952 Brompton Lake Fish & Game Club.6952 Canton Boyer Fish & Game Association Inc.6952 Club l'Aventure inc.6952 Club Bébé.6952 Club Belles Truites inc.6952 Club de C.& P.au lac Kaniapiskau.6952 Club de chasse et pêche Château Brillant inc.(Le).6952 Club de chasse & pèche le Monteux dc Nicole! (Le).6952 Club de chasse & pêche Pijo .6952 Club de chasse & pêche Scenic inc.6952 Club dc chasse et de pêche Si-Fo inc.6952 Club de chasse Provencher.6952 (lub de chasse Squawcap.6952 Club « Circle » Club.6952 Club les Copains inc.6952 GAZETTE OFFICIELLE DC QUEBEC.novembre 1973.10n' année, n\" 47 7065 lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled.(suite) (continued) Club Désiré inc.6952 Club E.O.Larivière.6952 Club des Garces.6952 Club Gaspé nord.6952 Club Gilbcrte inc.6952 Club Ha-Ro-Ma-Ma inc.6952 Club de la Haute Montagne.6952 Club Horizon.6952 Club Impérial.6952 Club Isabeau inc.6952 Club Jacqu'elo inc.6952 Club Joveux.6952 Club Kaosis Kakimat.6952 Club du lac Blanc.6952 Club du lac Boisvert.6952 Club du lac des Canards Huppés.6952 Club du lac Cboate inc.6952 Club du lac des Côtes.6952 Club du lac Deschênes.6952 Club du lac Fin.¦.6952 Club du lac des Joncs inc.6953 Club du lac Lafiolc.6953 Club du lac Léon.6953 Club lac Lézard.6953 Club du lac à Louis.6953 Club du lac Louise.6953 Club du lac aux Loutres.6953 Club du lac Martin inc.6953 Club du lac Misérable inc.6953 Club du lac Plat.6953 Club du lac de la Pointe Brûlée inc.6953 Club du lac Rimouski.6953 Club lac dc la Rivière-du-Loup.6953 Club lac Sommet dc Mont-Joli.6953 Club du lac Susanna .6953 Club du lac Violon.6953 Club Lacona inc.6953 Club Lafiteau.6953 Club de la Landioche inc.6953 Club Langiro.6953 Club Langis.0953 Club Lapin Blanc .6953 Club Laurencelle inc.6953 Club Laurier.6953 Club Lccompte.6953 Club Léger.6953 Club de la Lièvre de Kiamika inc.6953 Club Lignalcau.6953 Club Lola.6953 ClubLorette.6953 Club des Ixiuis inc.6953 Club Louis Léon.6953 Club Macaribo inc.6953 Club Maison blanche.6953 Club Malbo inc 6953 Club Manigo inc.- 6953 Club Manigouche inc.,T\\ Club Maravnord inc.6954 Club Maréchal .»9o4 Club Marian.6954 Club Marie-France.6954 Club Mariste.6954 ClubMarlène.6954 Club Marsoui.6954 Club Mathieu.6954 Club Mauricie inc.6954 Club Mav Flower inc.6954 Club Mc Nidcr.6954 Club méchanique.6954 Club Meilleur.6954 Club Mercedes des Ours.6954 Club Merveille (Le).6954 Club Michel.6954 Club du millage vingt-neuf.6954 Club Millecharme inc.6954 Club Mistassibi.6954 Club Mistouk.6954 Club du mont Alexandre inc.6954 Club mont Joli.6954 Club des montagnes escarpées inc.6954 Club de la montée.6954 Club Morin et Mouette.6954 Club Moselle inc.6954 Club Mouchawa.6954 Club Movette.69.54 Club des Nénuphars.6954 Club Nepton inc.6954 Club Nipop'.'ilgrajan.6954 Club Niverville.6954 Club Nodomat.6954 Club Noël inc.6954 Club Notrc-Damc-de-Pontmaiii inc.6954 Club Ortona.6954 Club Os-Du-Ro-Co.6954 Club Ou Va.6955 Club Ouapishish.6955 Club des Ours.6955 Club de l'ours blanc inc.6955 Club Ouskondor inc.6955 Club aux Outardes inc.6955 Club Pacifique inc.6955 Club Painchaud.6955 Club Palachc inc.6955 Club Panorama.6955 Club Papou.6955 Club Pascher.6955 Club passe-partout inc.6955 Club des Patients inc.6955 Club Patricia.6955 Club Patrick est .\"955 Club de pêche Guay & Savard inc.6955 Club de pêche Lo-Ri-Mi inc.6955 Club des petits lacs inc.6955 Club Pigalle.8955 Club Pimbina inc.6955 Club des pins rouges.6955 Club Pitou inc.«N» Club îles Plaines inc.Club Pointe du N'ord-Da.69oo 7066 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 24.1973, Vol.105, No.47 Lettres patentes annulées: Letters Paient Annulled: (suite) (continued) Club des policiers & pompiers de la ville de Port Alfred.6955 Club Populeau.6955 Club des portes de l'Estrie inc.6955 Club Poup-Poup.6955 Club des Prêtres inc.6955 Club Quatre Saisons inc.6955 Club de la rame.6955 Club du rapide Manigance.6955 Club des Rapides.6955 ClubRay-Hec.6955 Club Le Refuge inc.6955 Club Richelieu inc.6955 ClubleRikois.6956 Club Robb.6956 Club Robin des bois.6956 Club des Rochers.6956 Club aux rochers blancs inc.6956 Club de la Rocheuse inc.6956 Club Rocheux inc.6956 Club des Roland.6956 Club Roland inc.6956 ClubRomaléo.6956 Club Ro-Pel-Va.Club de ruisseau enchanté Club ruisseau jaune.Club du ruisseau Rouge inc 6956 6956 6956 6956 Club Rusticana.6956 ClubTarran.6956 Club Tekakouita inc.6956 Cocomo Club.6956 Denny Fish & Game Club Inc.(The).6956 Ettezag Fish & Game Club.6956 Fédération des clubs de cliasse et pêche du Bras-Hamel.6956 Fishing and Hunting Club Poupore.6956 Gatineau-Pontiac Fish & Game Club.6956 Giguère Fish & Game Club.6956 Grand'Mère Fish and Game Club.6956 Hammer Lake Club.6956 Howmark Corp.Ltd.(Erratum).7053 Joshua Lake Club.6956 Lake Lareau Fish & Game Club.6956 Laval Rod & Gun Club.6956 Pumpkinseed Club.695/ Québec Jay Fish & Game Club (The).6957 RavmerClub.- 6957 Rcaf St.Hubert Fish and Game Club.6957 Rivière aux Roches Hunting & Fishing Club 6957 Rosemere Country Club Inc.6957 St.Bernard Fish and Game Club.6957 Sea Gull-Gerland Lake Fish & Game Club.6957 Shannoosh Fish & Game Club Inc.6957 Sidney Lake Fish & Game Club.6957 Société de chasse et de pêche du coeur de Québec.695/ Square Forks Fish and Game Club.6957 Stanlev Roxton Pond Club Inc.6957 Ten-E-Ga Club Inc.6957 Vennor Lake Fish & Game Club.6957 WabakClub.6957 Wabenaki Fish and Game Club.6957 Weekechum Fish & Game Club Inc.6957 White Mountain Club.6957 White Pine Fishing and Hunting Club.6957 Services de Santé Health Services et services sociaux and Social Services Loi sur les Act Centre de services sociaux Richelieu (L.P.).7027 Centre local de services communautaires Arthur Caux (L.P.).7026 Centre local de services communautaires St- Henri (L.P.).7026 Résidence Bicrmans (L.P.).7027 SOUMISSIONS TENDERS \u2014 demandes de Requests for Aylmer.ville-town.7040 Beaconsfield.cité-city.7031 Deschênes, village.7032 Grande-Vallée, munie.7035 La Pocatière.ville-town.7038 Saint-Pierre-de-Sorel, par.(Erratum).7053 Saint-Joseph-de-Beauce, ville-town.7034 Senneterre.ville-town.7037 SYNDICATS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL SYNDICATES Mansonville Hunting & Fishing Club.6956 Fédération des cadres scolaires (Exist, terms.) 7048 Mazurka Inc.\".6956 Mc Can Lake F.& G.Club Inc.6956 Memphremagog Fish and Game Club.6956 Mille Isles Club.6956 Moppe Lake Club.6956 Mountain Crest Fishing & Hunting Club Inc.6956 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Goods CP Express Limited.7027 Napetipi Fish and Game Club.6956 Cie des Messageries CP limitée (La).7027 New Derecn Club Inc.6957 Parna Fish & Game Club.6957 Pine Brook Hunting Club.6957 Pinnacle Club.6957 Point Rock Fish and Game Club Inc.6957 Par Shérifs By Sheriffs Bedford Bedford Associates Realty Credit Ltd.M Latour et al 7048 Police Fish & (lame Club.6957 Péloquin vs Péloquin.7049 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, JJ, novembre 1973, 105' année, n° A7 7067 Gaspé Gaspé Farrah m Leblanc.7049 Joliette Joliette Banque Royale
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.