Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 1 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-12-01, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES 1er DECEMBRE 1973 N° 48 7071 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973.105' année, n° 48 7073 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazelle is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties arc requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Officiai Publiiher 7074 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 1st.1973, Vol.105, No.48 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazetle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion : 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation : $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1) : from 1 January to 31 December, $20; from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubê, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 18 7075 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gaulle officielle de ce deuxième avis.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazelle of this second notice.Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Incorporation Date A.B.CLUB CHASSE & PECHE.A.L.INDUSTRIES & CO (67) LTD.A.M.SPORTS INC.A M X METAL INDUSTRIES INC.A & R INVESTMENT CORP.ABENAKI FISH AND GAME CLUB INC.LES ALOUETTES DE ROUYN-NORANDA INC.AL-QUA INC.ALUCO ALUMINIUM INC.LES ALUMINIUMS RESIDENTIELS INC.ALUMINUM WINDOW INDUSTRY ASSOCIATION.LES AMATEURS DE BASEBALL DE LA BAIE INC.AMBRADOR PAINT COMPANY LTD.AMBULANCE SECURITE (SHERBROOKE) INC.AMEDECOR LTEE.AMERICAIN REALTY INVESTORS CORP.LES AMEUBLEMENTS C.S.INC.AMICALE DES INFIRMIERS DE L'HOPITAL NOTRE-DAME DE L'ESPERANCE INC.L'AMICALE DE LA RIVE-SUD INC.AMICO REALTIES LTD.AMIENS GARAGE AUTO PARTS INC.LES AMIS DU BASEBALL DE KENOGAMI INC.LES AMIS DU MONT FORTIN DE KENOGAMI.LES AMIS DU STUDIO 437.AMOR HANDBAGS LTD.LES AMUSEMENTS LAVAL LTEE.ANADA INVESTMENT CORP.ANDA MINES LIMITED.Joliette.05 05 1964 Montreal.03 04 1967 Alma.09 12 1969 Montréal.25 05 1971 Montreal.20 03 1963 Sherbrooke.29 07 1958 Noranda.05 11 1963 Jacques-Cartier.01 05 1969 Pointc-aux-Trcmbles.31 05 1971 Jacques-Cartier.26 04 1967 Montreal.17 05 1966 Bagotville.13 05 1966 Montreal.01 01 1970 Sherbrooke.19 12 1969 Montréal.05 11 1970 Montreal.25 04 1962 Montréal.04 11 1966 Ville St-Laurent.12 06 1959 Longueuil.13 03- 1970 Montreal.07 01 1958 Montréal.14 04 1967 Kénogami.12 OS 1963 Kénogami.13 11 1967 Québec.15 11 1963 Montreal.19 04 1967 Dorval.01 03 1965 Montreal.11 05 1959 Montreal.29 04 1971 7076 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st.1973.Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company\tAddress\t\tDate\t \t\t08\t10\t1964 \t\t\tM\t1961 ANVIL LAKE FISH & GAME CLUB (THE).\t\t.25\t06\t1965 ASS.DE C.& P.DE LA COTE DE BEAUPRE INC.\t\t30\t12\t1966 L'ASSOCIATION DES AMIS D'EMILE NELLIGAN INC.\t\t06\t09\t1966 ASSOCIATION DE C.& P.DE BROMPTONGORE INC.\tWindsor Crirhmond.\t.19\t01\t1967 ASSOCIATION DE C.& P.DES ESCOUMINS INC.\tLes Escoumins.\t21\t05\tl'.i.ls L'ASSOCIATION DE CHASSE DE CANARDS ET D'OUTARDES DU\t\t12\t1 !\t1954 DISTRICT DES TROIS-RIVIERES.\t\t\t\t ASSOCIATION CHASSE & PECHE AYLMER.\tDisraeli.\t21\t03\t1957 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DES CANTONS DE\tEast Broughton.\t10\tor,\t1967 BROUC.HTON.\t\t\t\t ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DE CAP-CHAT.\tCap-Chat.\t04\t01\t1960 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE DORCHESTER.\tSte-Aurèle.\t16\t06\t1960 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DU LAC DES SUCRERIES\t\t08\t06\t1958 DE VENDEE.\t\t\t\t ASSOCIATION DE CHASSE & PECHE DE LA MACAZA.\t\t30\t08\t1966 ASSOCIATION DE CHASSE & PECHE DE NORMETAL.\tNormetal.\t20\t05\t1965 ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DU PETIT LAC LONG.\tSte-Agathe-d es-Monts.\t.11\t11\t1957 ASSOCIATION DE CHASSE & PECHE DU PIC CHAM PLAIN.\tSt-Fabian.\t12\t12\t1966 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE POINTE ST-CHARLES.\t\t22\t04\t1966 ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DE PORT-CARTIER\tPort-Cartier.\t21\t06\t1960 L'ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DE RIVIERE-A-PIERRE\t\t26\t00\t1964 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DE ST-GABRIEL.\tStratford.\t24\t01\t1957 ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PECHE DE ST-MARTIN DE\t\t11\t12\t1959 BEAUCE INC.\t\t\t\t L'ASSOCIATION DES CHASSEURS CANADIENS ITALIENS DE\t\t22\t10\t1963 QUEBEC.\t\t\t\t L'ASSOCIATION DES CITOYENS DE LASALLE, QUARTIER NO 1 INC.\t\t06\t12\t1960 L'ASSOCIATION DES CLUBS DE PECHE ET CHASSE DE LA\tPort-Alfred.\t24\tOs\t1956 RIVIERE-DU-MOULIN.\t\t\t\t L'ASSOCIATION DES EMPLOYES CIVILS DU BAS ST-LAURENT INC.\t\t25\t06\t1967 ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA PLACE CREMAZIE.\t\t15\t10\t1963 ASSOCIATION PAROISSIALE TOURISTIQUE DE RIVIERE-A-PIERRE.\t\t22\t07\t1965 L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES UNIS DE LAVAL CENTRE.\t\t22\t01\t1968 ASSOCIATION DE LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE L'ASSAI-\t\t20\t12\t1960 NISSEMENT DES EAUX DU QUEBEC INC.\t\t\t\t ASSOCIATION SPORTIVE DE CHASSE & PECHE DE LA VALLEE\tS t-Alexis Station.\t21\t10\t1968 INC.\t\t\t\t ASSOCIATION SPORTIVE DES DISCIPLES DE NEMROD INC.\tPointe-aux-Trembles.\t23\t01\t1969 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n\" 1,8 7077 Nom de la compagnie Name of the company ASSOCIATION DES VETERANS ET ANCIENS COMBATTANTS DU QUEBEC AU CROQUET INC.AU MANOIR DE LA CALECHE (ST-FELICIEN) LTEE.BARRY EXPLORATIONS LIMITED.BEACH FISHING AND HUNTING CLUB.BELANGER TABACONISTE INC.BOUCHERIE AMICALE LTEE.BOUTIQUE MONIQUE INC.BOUTIQUE NICOLE FRANCE INC.LA BOUTIQUE DU SAC (NORMANDIE) LTEE.BOUTIQUE DU SKI ALPIN INC.BOUTIQUE ZIGBY INC.BRASS MUSIC PUBLISHERS INC.BRIFOR INC.THE BRIGADIER FREDERICK KISCH REMEMBERANCE FUND INC.BROADLOOM' 67 LTD.BUCKHORN FISH & GAME CLUB.BURKHARDT INDUSTRIAL SUPPLY CO.LTD.CAMEO INDUSTRIES CORPORATION.CAMPING SAINTE SOPHIE INC.CANADIAN AUTO STAIR-AID LIMITED.CANADIAN SCHOOL OF MENTAL AND PSYCHIC DEVELOPMENT INC.CAP ALUMINIUM PRODUCTION INC.CARON, CONSULTANT EN ADMINISTRATION INC.CENTRE DE GESTION POLYVALENT DU QUEBEC (C.G.P.Q.) LTEE.CEPAC INC.CHAMPAGNE ENTREPRENEUR GENERAL INC.CHATEAUGUAY AMATEUR ATHLETIC ASSOCIATION.CHEVALIERS ET CHEVALIERES DE CROTEAU INC.CIE DAGEX (CANADA) LTEE.CITADEL ALUMINIUM INC.LES CITES JARDINS DU QUEBEC INCORPOREES.CLUB A.C.CLUB A.R.C.O.CLUB ALBERT.CLUB AMICAL UDES.Adresse Address Incorporation Date Chambly.\t28\t07\t1969 \t18\t12\t1968 St-Félicien.\t29\t12\t1971 \t16\t1 1\t1954 \t\t02\t1955 \t29\t09\t1965 Montréal.\t08\t10\t1968 \t15\t07\t1965 Montréal.\t08\t07\t1968 \t10\t01\t1964 \t04\t02\t1969 \t17\t05\t1972 \t22\t06\t1966 \t19\t05\t1965 \t13\t12\t1971 \t28\t08\t1967 \t20\t03\t1956 St^Laurent.\t14\t00\t1971 \t11\t05\t1966 \t07\t09\t1971 \t26\t04\t1972 \t06\t04\t1972 Cap-de-la-Madeleine.\t.20\t07\t1965 Cap-de-la-Madeleine.\t.17\t01',\t1971 Québec.\t25\t09\t1970 Sherbrooke.\t20\t12\t1970 \t03\t06\t1971 \t15\t07\t1965 \t27\t11\t1961 \t01\t06\t1970 Ste-Foy.\t25\t09\t1970 \t17\t04\t1941 \t29\t03\t1963 Shawinigan.\t11\t06\t1965 \t\t03\t1951 Salaberry-de-Valleyfield.18\t\t08\t1965 7078 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company CLUB AN-GI-LOU INC.CLUB ARTHUR INC.CLUB ARVISAIS INC.CLUB AUTOMOBILE AMOS INC.CLUB DE C.& P.ASSELIN.CLUB DE C.& P.COLOMBIEN INC.CLUB DE C.& P.NORD-OUEST INC.CLUB CANARI INCORPOREE.CLUB DES CASTORS DE BUCKINGHAM.CLUB DU CHARME.LE CLUB DE CHASSE ET PECHE DE CHAMBLV INC.CLUB DE CHASSE A PECHE DE CITE JACQUES CARTIER.CLUB DE CHASSE & PECHE L'ESPERANCE INC.CLUB DE CHASSE & PECHE LES HARDIS PECHEURS.CLUB DE CHASSE ET PECHE DU LAC CROCHE (LE).CLUB DE CHASSE & TECHE DU LAC LEBEL INC.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE McTAVIS.CLUB CHASSE & PECHE PELISSIER INC.CLUB DE CHASSE ET PECHE DE LA RIVIERE SAUVAGE INC.CLUB DE CHASSE ET PECHE ROLLAND COTE INC.CLUB DE CROSSE LES JETS DE DRUMMONDVILLE.LE CLUB DE CROSSE NATIONAL LTEE.LE CLUB DE CURLING DE REPENTIGNY.CLUB D.CAMPEZ INC.CLUB DES DEUX VERSANTS INC.CLUB DE L'ECLUSE INC.CLUB FLEUR DE LYSEES.CLUB GAUPO INC.CLUB GOUGER & PELLETIER INC.CLUB HIRONDELLE PEARL LAKE.CLUB JACKSON.CLUB JEAN-MARIE INC.CLUB DU LAC GRENON.CLUB DU LAC MOÏSE INC.CLUB DU LAC PISTON.CLUB LU LAC TOULADIE.CLUB DU LAC A LA TOURTE.Adresse Address Incorporation Date Ste-Thérèse-de- 14 015 1962 Blainville Chicoutimi.21 09 1961 St-Joseph-de-Sorel.02 04 1963 Amos.20 03 1969 Rimouski.14 06 1963 La Tuque.05 05 1959 Port-Cartier.25 09 1961 Aima.15 03 1962 Buckingham.01 12 1970 La Sarre.01 10 1964 Chambly Bassin.23 04 1951 Jacques Cartier.02 05 1963 Ange-Gardien.30 08 1957 Shawinigan Falls.09 05 1956 Huntingdon.25 30 1957 St-I.éandre.02 12 1958 Montréal.17 12 1915 Amos.22 02 1957 LamUon.02 02 1956 Montréal.29 05 1962 Drummondville.25 08 1970 Montréal.04 01 1965 Repentigny.21 10 1964 St-Michel-des-Ssints____ 07 01 1959 St-Nazairo.14 05 1958 St-Pascal.20 03 1900 Squattcck.24 10 1947 Notre-Dame-du-Laus.06 10 1961 St-Côme.24 09 1958 Québec.26 05 1948 Lac Carré.20 07 1964 St-Michel-dcs-Saints____ 18 11 1958 Québec.15 01 1954 La Malbaie.07 02 1956 Montréal.23 11 1955 Dolbeau.11 11 1952 St-Hyacinthe.20 03 1953 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n' 48 7079 Nom de la compagnie Name of the company CLUB DES LACS JUMEAUX.CLUB LAGACE.CLUB LAYNE.CLUB LECOQ INC.CLUB LENOIR INC.CLUB MANIWAWA.CLUB DE MOTO-NEIGE LES OURS BLANCS INC.CLUB MUSKUTCHOU.CLUB NAUTIQUE DE LA MATAPEDIA INC.CLUB NEA INC.CLUB NEMROD INC.CLUB NIQUET.CLUB NORBEAU INC.CLUB O-CAMP.CLUB DES OPTIMISTES.CLUB LE PARADIS DE L'ORIGNAL.CLUB PAROISSIAL ST-PIE X INC.CLUB PATRY\" INC.CLUB DE PECHE ET DE CHASSE DENIS.CLUB DE PECHE DU LAC VERT DE ST-ALPHONSE DE RODRIGUEZ CLUB PERIGNY.CLUB PHEBE INC.CLUB PIERRICHE.CLUB PONT DU CHAT.CLUB DE RAQUETTE «LE SALABERRY ».CLUB DE RAQUETTEURS LE COURAGEUX INC.CLUB RUISSEAU BLEU DUC.CLUB ST ESPRIT INC.CLUB STE MARTHE SUR LE LAC INC.CLUB LA SECHE INC.CLUB DES SEPT DIABLES.CLUB DE SKI ALPIN DE MALART1C.CLUB DE SKI ELAN INC.(LE).CLUB DES SORCIERS INC.CLUB TATAWEE.CLUB LES TROIS CARIBOUS INC.CLUB VACHON.Adresse Incorporation Address Date Les Escoumins.24 05 1957 L'Abord-:VPlouffe.24 03 1954 St-Lambert.15 09 1950 Dolbeau.09 01 1959 St- Jérôme.08 10 1957 Montréal.03 04 1963 Blue Sea.18 01 1972 Port Cartier.27 07 1961 Causapscal.02 07 1959 Terrebonne.27 05 1960 Thetford Mines.02 09 1960 Jonquiére.01 04 1952 Huil.03 03 1961 Ottawa.14 01 1965 Terrebonne.25 01 1966 St-Joseph d'Aima.21 04 1947 Chûte-dcs-Passes.29 08 1961 St-Martin.27 05 1960 Crabtree Mills.16 01 1957 Rosemont.24 04 1957 Québec.19 04 1963 St-Sauveur-des-Monts., 02 06 1966 La Tuque.25 06 1954 BaieSt-Paul.08 04 1964 Valley field.23 05 1944 Montréal.13 09 1968 Gaspé.03 06 1960 L'Ephiphanie.14 02 1958 Ste-Marthe-sur-le-Lac.24 05 1966 Shawinigan.19 09 1961 Lac Carré.28 05 1947 Malartio.08 05 1970 Montréal.27 02 1973 Beaupré.14 08 1961 Beaupré.15 07 1963 Labrieville.21 02 1958 Rimouski.27 12 1951 7080 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Xame of the company\tAddress\t\tDate\t \tLa Tuque.\t.20\t05\t1959 LE COQ FISH & GAME CLUB INC .\tGagnon.\t17\t07\t1961 COMMISSION DE BOXE AMATEUR DU B\\S ST-LAURENT INC.\tRivicre-du-Loup.\t19\t11\t1964 COMPAGNIE DE BOIS ANDRE LTEE .\tRimouski.\t22\t10\t1945 COMPAGNIE DE BRIQUE ET PIERRE CANADIANA LIMITEE.\t\t13\t02\t1967 LA COMPAGNIE FRANCEBEC INC\t\t\t06\t1965 LA COMPAGNIE DE GESTION B & Y INC .\t\t15\t09\t1971 CONSTRUCTION CYR & FRERES INC .\t\t03\t02\t1970 LA CORPORATION DES CREATEURS ARTISANS DE LA REGION DE L'EST DU QUEBEC\tNew Richmond.\t.28\t06\t1972 \tBaie St-Paul.\t08\t11\t1972 LA CORPORTION DES LOISIRS ST-ANDRE INC.\t\t23\t12\t1963 THE COTE ST-LUC 4MATEUR ATHLF.TIC ASSOCIATION INC\t\t24\t11\t1966 COUTURE ET ASSOCIES INC.\t\t13\t06\t1967 CREATIONS CHANTAL INC.\t\t13\t08\t1968 CREATIVE ENTREPRISES INC.\t\t03\t11\t1966 CRECEL INC.\tQuébec.\t14\t09\t1959 CREDICHEX INC.\t\t13\t11\t1970 CREMERIE DESROSIERS LTEE.\t\t16\t01\t1958 CRESCENT FABRICS LTD.\t\t01\t02\t1966 CRESCENT MANAGEMENT CORPORATION.\t\t25\t07\t1962 CRESTA CONSTRUCTION INC.\tMontreal.\t12\t04\t1960 CRESTVIEW INVESTMENTS LIMITED.\t\t21\t10\t1963 CRETAN'S ASSOCIATION OF MONTREAL.\t\t14\t08\t1962 \t\t\t01\t1960 \t\t11\t11\t1970 \tDollard-des-Ormeaux.\t.11\t01\t1966 CURMAC LIMITED.\t\t07\t03\t1966 \t\t\t02\t1970 CYCLO-JONQUIERE INC.\t\t29\t05\t1962 \tSte-Foy.\t31\t10\t1966 CYR BISCUITERIE INC.\t\t09\t12\t1963 DABOR INVESTMENT CORP.\t\t15\t07\t1959 ROBERT P.DAIGLE INC.\t\t02\t11\t1964 DAIGNAULT & FILS INC.\t\t16\t06\t1964 ROGER D'AMOUR INC.\tHull.\t11\t06\t1963 DECORAMA INC.\t\t27\t06\t1972 DENTONEX INC.\t\t25\tOS\t1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 197.3, 105' année, n° 48 7081 DEVELOPPEMENT MON-TAL INC.\tSt-Henri-de-Mascouche.\t19\tOS\t1972 \t\t¦1\\\t04\t1969 DONALDSON CREVIER AND ASSOCIATES INCORPORATED.\tMontreal.\t10\t01\t1964 DURABLE ALUMINUM PRODUCTS LTD.\t\t05\t11\t1964 ECOLE DE SKI NAUTIQUE DE MONT LAURIER.\tMont-Laurier.\t08\t07\t1971 \t\t17\t07\t1968 LES ENTREPRISES DACA INC.\t\t20\t12\t1968 \t\t30\t11\t1970 LES ENTREPRISES JOUR & NUIT INC.\t\t31\t11\t1968 \tMontréal.\t28\t04\t1971 \tSte-Foy.\t20\tOS\t1955 \tLemoyne.\t21\t02\t1969 \t\t05\t05\t1972 \t\t31\t01\t1967 \tMontréal.\t08\t02\t1972 \t\t\t\t \tMontreal.\t09\t12\t1971 \t\t07\t03\t1972 FINESTONE TRAILER & CAMPING EQUIPMENT INC.\t\t01\t08\t1966 \tSte-Foy.\t14\t08\t1969 \tMontreal.\t02\t10\t1968 \t\t20\t03\t1967 \t\t02\t02\t1968 \tMontréal.\t25\t09\t1969 \t\t13\t11\t1968 \tGreenfield Park.\t01\t12\t.1967 \t\t04\t05\t1961 \t\t26\t05\t1966 \t\t02\t04\t1971 \t\t12\t10\t1965 \t\t24\t09\t1965 \t\t26\t01\t1959 \tHull.\t29\t12\t1967 \t\t17\t06\t1969 \t\t03\t02\t1969 \t\t20\t11\t1967 \t\t14\t04\t1967 \t\t11\t03\t1969 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date 70S2 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Dollard-des-Ormeaux.12 06 1970 Repentigny.21 10 1968 Québec.17 11 1967 Duvernay.28 07 1965 Montreal.18 11 1971 Ste-Foy.29 05 1970 Mont-Laurier.02 07 1971 St-Aubert.29 01 1971 Lambton.27 11 1969 Hull.08 11 1971 Montreal.27 01 1967 Jacques-Cartier.11 03 1964 Scardale (N.Y).06 05 1958 St-Laurent.09 06 1961 Trois-Pistoles.28 12 1961 Laval.02 02 1967 Québec.31 10 1963 Montreal.31 05 1972 Montréal.03 09 1971 St-Pierre.21 12 1964 Gaspé.19 04 1966 Montreal.21 10 1971 Rivière-du-Loup.16 05 1967 Montreal.13 05 1955 Laval.18 02 1970 Ste-Rose.08 03 1955 Montreal.01 06 1966 Montreal.30 11 1967 Montreal.06 09 1961 Montreal.05 10 1972 Salaberry-de-Valleyfield.07 03 1972 Montreal.11 08 1964 Montreal.29 04 1970 St-Laurent.27 04 1965 St-Félicien.21 07 1969 Montreal.10 02 1964 Pointe-aux-Trembles.27 12 1967 HUTTON FOOD SERVICE INC.LES IMMEUBLES NORMAN ROBINSON INC.LES IMMEUBLES S.B.S.LTEE.IMPERIAL ALUMINIUM PRODUCTS CO.LTD.IMPRIMERIE I.M.INC.IRVING ALUMINUM PRODUCTS INC.J.K.WHOLESALERS LTD.J.J.JASON INC.LA JEUNE CHAMBRE DE LA REGION DE LAMBTON, FRONTENAC INC.K & M PANTADISC INC.KEBEC PIZZA CRUST CO.L.M.ALUMINUM DOORS & WINDOWS CO.LTD.LACS A LA CROIX WESTERN FISHING AND HUNTING CLUB INC.LAMOTHE INC.J.M.LARRIVEE LTEE.LAVAL BUSINESS FORMS INC.ARMAND LEPAGE INC.LIA TRAVEL AGENCY LTD.LIBRAIRIE DE LA NOUVELLE-FRANCE.LA LIGNE DE CROSSE DU QUEBEC.LES LOISIRS DE GASPE INC.A.E.LUPESCO COSMETICS LTD.M A O LTEE.MADISON MINING CORPORATION.MARCHE BUDGET INC.MILLE ISLE ANGLERS & HUNTERS ASSOCIATION.MISS MONTREAL CURB SERVICE LTD.MONACO-LITHO INC.MORTGAGE BROTHER'S ASSOCIATION OF QUEBEC.MULTIPLES SERVICES MENAGERS (MONTREAL) INC.MUTI-VENTURES HOLDINGS CORPORATION.N.P.CONSTRUCTION AND RENOVATION INC.NOR-AM CORPORTION.NORCRED HOLDINGS LTD.NORDIC ALIMENTATION LTD.NORFRED CORPORATION LTD.NORMAD INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1973.105' année.n° 48 7083 Nom de la compagnie Same of the company NORMANDIN TRANSPORT LTEE.NORMAR INVESTMENTS INC.NORMEZ INC.NORSPEC INC.NORTHERN TELECOMMUNICATIONS INC.NORTHLAND SHOPPING CENTRES (CANADA) LIMITED NORTHWAY LEASING LTD.NORTON CONSTRUCTION LTD.ONTARIO CUVILLIER CAR WASH INC.PAN-AM BUILDING CORP.LES PLACEMENTS NORMAND INC.POINT NOIR INC.POINTE CLAIRE AMATEUR ATHLETIC ASSOCIATION.POINTE GLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION.PORTUGUESE CULTURAL CENTRE OF CANADA INC.POUPORE FISHING AND GAME CLUB.PRODUCTIONS NOIR 4 OR INC.PRODUITS BELANGER INC.PRODUITS LAITIERS CRETE DE LA MAURICIE INC.LES PROFILES D'ALUMINIUM DU SAGUENAY LTEE QUALITY PARQUET FLOORING MANUFACTURING INC.QUARTIS INC.RESTAURANT PLACE CREMAZIE LTEE.ROUSSEAU ENTERPRISES LTD.ROVER FISH A GAME CLUB.ROY GILLINGS AGENCIES INC.RUSSELL ALUMINUM PRODUCTS LTD.ST.LAURENT AUTO ENTERPRISES INC.LA SALAISON BROSSARD INC.LA SALLE BEAULIEU D'AMQUI INC.SALON FUNERAIRE ARTHUR BELISLE INC.SERVICE DES LOISIRS ST BRUNO DE LAVAL.SERVICE DES LOISIRS SAINT ANDRE APOTRE.SERVICE & TRANSPORT DU ST LAURENT LTEE.SHIRTBOARD ADVERTISING INTERNATIONAL CORP.SIMCO ALUMINIUM LTEE.LA SOCIETE DES AMIS DE L'ART DE SHERBROOKE Adresse Address Incorporation Date Normandin.\t22\t03\t1965 \t30\t(il\t1967 \t22\t12\t1970 Ste-Agathe-des-Monts.\t23\t08\t1967 \t19\t07\t1960 \t08\toa\t1966 Dorval.\t26\t09\t1970 \t16\t08\t1966 Montreal.\t02\t08\t1965 \t21\t04\t1969 \t27\tKl\t1970 \t20\t(Il\t1969 \t20\t09\t1966 \t12\t(il\t1967 Montreal.\t25\t09\t1969 \t07\tu\t1962 Lachine.\t31\ti«\t1970 Montréal.\t17\t05\t1969 \t27\tor,\t1967 \t17\t09\t1963 Laval.\t20\t08\t1968 \t09\t02\t1972 \t03\t12\t1963 \t06\t(il\t1970 Verdun.\t10\t(IS\t1955 \t13\t08\t1970 Laval.\t29\tin\t1966 St.Laurent.\t24\t08\t1970 \t27\t11\t1966 \t09\t04\t1970 Sherbrooke.\t28\t(IS\t1970 \t12\t(il\t1967 \t12\t04\t1955 \t06\t08\t1969 \t12\t02\t1971 \t20\t()7\t1967 \t.02\t(il\t1970 7084 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Incorporation Date SOCIETE GENERALE ALOUETTE INC.SOCIETE GENERALE D'ALUMINIUM DU QUEBEC INC.SOCIETE DES INFIRMIERES VISITEUSES.STUDENT ENTERPRISES LIMITED.SUN CLUB INC.T & C TOURS LTD.TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENTS EDUCO INC.THEATRE COMPAGNIE DES INSOLENTS INC.TRANS-CANADA WIRE & METAL PRODUCTS LTD.LES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES LTEE.PAUL A.TREMBLAY MARINE OUTBOARD INC.TROUPE FOLKLORIQUE FEUX-FOLLETS INC.LES TUYAUX D'AMIANTE DU QUEBEC INC.UNI-CULTURE INC.L'UNION ECONOMIQUE D'HABITATIONS.VETERANT CURLING CLUB INC.WILDERTON GARAGE INC.WOOL'N CRECHE INC.Montréal.01 03 1963 Montréal.02 08 1966 Montréal.08 11 1939 Montreal.20 07 1971 Montreal.31 08 1961 Montreal.03 05 1967 Laval.11 08 1965 Val d'Or.04 11 1966 Anjou.07 03 1967 Montréal.09 09 1965 St-Anicet.31 03 1964 Montréal.06 04 1960 Montréal.09 07 1964 Montréal.28 10 1970 Montréal.25 10 1940 Verdun.26 03 1965 Montréal.11 10 1967 Montreal.13 04 1967 54865-o Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.54865-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Erratum Les noms de compagnie énoncés ci-après ont été inclus par erreur dans des avis de lettres patentes annulées dans la Gazette Officielle du Québec.En effet, les compagnies concernées ont produit dans les délais fixés les rapports requis par le ministre dans un avis antérieur.En conséquence, vu l'article 5d de la Loi des renseignements sur les compagnies, avis est donné que lesdites compagnies n'ont pas été dissoutes par la publication desdits avis de dissolution.Erratum The names of the companies, hereinafter mentioned have been included by mistake in notices of letters patent annulled published in the Québec Official Gazette.In fact, the companies concerned have produced, within the prescribed time limits, the reports required by the Minister in a previous notice.Therefore, in compliance with section 6d of the Companies Information Act.notice is given that the said companies have not been dissolved by the publication of said notice of dissolution.Nom de la compagnie Xame of the Company Date de constitution Date of I ncorporation Date de lettres patentes annulées Date of letters patent annulled CLUB DU LAC OURSON.\t\t09\t60\t13\t10\t73 JEAN RATELLE INC.\t\t03\t72\t20\t10\t73 LE SORELOIS LTEE.\t\t0-1\t39\t03\t11\t73 54866-u Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardin6.54865-0 Pierre Debjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7085 Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.B.C.ELECTRORAMA CO.LTD.A & Vf ENTERPRISES INC.ACIER D'ARMATURE R.B.M.INC.AGENCE DE VOYAGES SOLEIL INC.LES AGENCES DUROY INC.ALFTAR CONSTRUCTION INC.ALIMENTATION DUBE LTEE.ALLA INC.ANTON MINERALS LTD.APARTMENT HOLDINGS INC.APPIA INVESTMENTS INC.LES APPRENTIS SORCIERS.AQUARIUS MINES LIMITED.ARCHITON LTD.ARELDEE CORPORATION.ARENA DE WARWICK INC.ARGA CORPORATION.ARIEL INVESTMENT CORP.ARMABEC INC.ARMAND AUTOMATE INC.ARNEF CORP.LES ARPENTS VERTS DE STE-JULIE INC.ARROW BUILDING AND INVESTMENT CO.LTD.ARROW DEVELOPMENT CORPORATION.ARSENAL DE L'AUTO LIMITEE.ARSIMA INC.ART PLASTICS PRODUCTS INC.ART-BO INC.ARTHUR'S INVESTMENT CORPORATION.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Val d'Or.1967.1969.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.St-Jean Eudes.1968 à/to 1973 incl.Verdun.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montréal.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Warwick.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.SULaurent.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Julie.1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1958, 1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1963 à/to 1973 incl.Valleyfield.1969, 1972, 1973 Montreal.1968, 1971 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl. 7086 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973.Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company LES ARTICLES DE SPORT DAYTONA LTEE.ARTISAN JEWELLERS INC.ARTISTIC SHOW ENTERPRISES INC.MARCEL ARVISAIS INCORPOREE.ASIACAN IMPORT EXPORT INC.ASSOCIATION DES AUTEURS & COMPOSITEURS DU QUEBEC ASSOCIATION DU BASEBALL JUNIOR DES ORIOLES DE VERDUN ASSOCIATION DE C.& P.DE BAIE COMEAU HAUTE RIVE INC.ASSOCIATION CANADIENNE DES JOURNALISTES ET ECRIVAINS DU TOURISME L'ASSOCIATION DES CITOYENS D'AUTEUIL.ASSOCIATION CIVIQUE DES LOCATAIRES D'OUTREMONT L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE DE VAL D'OR INC.ASSOCIATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PRA-TRICIENS DU SAGUENAY L'ASSOCIATION CULTURELLE DE TERREBONNE.L'ASSOCIATION DES DAMES AUXILIAIRES DE L'OPTO-METRIE ASSOCIATION DES EMPLOYES D'HOTELS ET DE CLUBS LICENCIES DES CANTONS DE L'EST L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DE QUEBECAIR.L'ASSOCIATION DES FAMILLES NOMBREUSES DU QUEBEC INC.ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS EN SCIENCES DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE L'ASSOCIATION DES GEOGRAPHES DU QUEBEC.ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE STE-FOY .L'ASSOCIATION DU LAC PORT AUX QUILLES INC.ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA CITE ET BANLIEUE DE QUEBEC INC.L'ASSOCIATION DES LOISIRS DE ST-MICHEL D'YAMASKA L'ASSOCIATION NAUTIQUE & SPORTIVE DU LAC ST-AUGUSTIN L'ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DE L'ECOLE REGIONALE DES MILLE ILES L'ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DE ROUGEMONT.L'ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DE STE-EUGENIE DE DOUVILLE INC.L'ASSOCIATION POUR.L'ENFANCE EXCEPTIONNELLE DU BAS ST-LAURENT Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Daveluyville.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1970 à/to 1973 incl.Hull.1964.1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Québec.1963 à/to 1973 incl.Verdun.1967 à;to 1973 incl.Baie Comeau.1972, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.D'Auteuil.1964 à/to 1973 incl.Outremont.1971 à/to 1973 incl.Val d'Or.1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Terrebonne.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1967 à/to 1973 incl.Dorval.1966 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1966 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1972 et/and 1973 Ste-Foy.1969/à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Sorel.1966 à/to 1973 incl.Lac St-Augustin.1949 à/to 1954 incl.1957 à/to 1959 incl.1971 à/to 1973 incl.Ste-Rose.1966, 1968 à/to 1973 incl.Rougemont.1970 à/to 1973 incl.Douville.1973 Rimouski.1967 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7087 Nom de la compagnie Name of Oie company L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CLUBS DU LAC KENOGAMI, DE LA PETITE POINTE ET DU LAC LONG ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU PARC DES PRAIRIES L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE RIVIERE DU LOUP INC.L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHASSE ET PECHE DE BONAVENTURE ASSOCIATION SPORTIVE KIROUAC.L'ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-MATHIEU INC.L'ASSOCIATION TOURISTIQUE DU COMTE DE MONTCALM INC.ASSOCIATION DES VETERANS PROPRIETAIRES BACHAND ATELIERS GILDRE INC.AU BAR DU MUSIC HALL INC.AU BUREAU BAR-SALON INC.AU VIEUX LOUP.AUSABLE MINES LIMITED (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) AUTOMATION DATA PROCESSING INSTITUTE LTD.AUTOROUTE AUTO INC.AVA CONSTRUCTION INC.AVY'S HOT DOGS LTD.AYLMER CONSTRUCTION LTD.THE AYLMER CORPORATION.AYLMER-LUCERNE ARTS COUNCIL INC.AZAD REALTIES INVESTMENT ESTATE SERVICES INC.AZET REALTIES LTD.B.B.SECURITY SYSTEM INC.J.BABB INC.THE RICHARD BABBAGE COMPANY.THE BABY BEARS INCORPORATED.BACQUE CONSTRUCTION INC.BADENIA INVESTMENTS INC.BAGNOLE AUTO-LAVE INC.BAGOT MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).BAIE COMEAU LIONS CLUB INC.BAILLARGEON EQUIPEMENT INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Jonquière.1969 a/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine .1968, 1970 à/to 1973 incl.Riviére-du-Loup.1965 à/to 1973 incl.St-Alexis.1971 à/to 1973 incl.Ste-Justine.1963.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.St-Mathieu.1966, 1971 à/to 1973 incl.St-Calixte.1962 à;'to 1973 incl.Chambly.1967 à/to 1973 incl.St-Hippolyte.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Matane.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Aylmer.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1952.1969 à/to 1973 incl.Aylmer.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1962 incl., 1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Chambly.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Neufchàtel.1971 à/to 1973 incl.Montreal.- 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Baie-Comeau.1962.1966.1968 à/to 1073 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl. 7088 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973.Vol.195, So.43 Nom de la compagnie A ame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LA BAJARDV INC.BALA DEVELOPMENT CORP.BALATON IMPORTS INC.BALMORAL CONSTRUCTION INC.BANTAM MINING LTD.BAR DES ILES INC.BAR ONE RESTAURANT INC.BAR SALON FRONTENAC INC.BAR SALON TV-COQ VOLANT INC.BARBEL INC.C.DE BARBIER REALTY CORP.LES BARBOUILLEURS DE VAL D'OR.BARCA FOOD SERVICES LTD.BARCA FOOD SERVICES (QUEBEC) LTD.BARCELONA INVESTMENT CORP.B A RI TRANSPARENT PAPER CO.LTD.LE BARIL SF.PT-ILKS INC.BOB BARNABE INC.BARON DE POULET INC.BAS MIRELLA INC.Longueuil.1971 à/to 1073 incl.Montreal.19G5 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Val d'Or.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1970 à/to 1973 incl.St-Eustache.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Anjou.197) ù/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Beaconsfield.1969 à/to 1973 incl.BATES ROAD INVESTMENT INC.BEACONSFIELD COMMUNITY ASSOCIATION.BEAUBIEN BAR-B-Q LTD.Montreal.1969 à/to 1973 incl.BELIVEAU SPORTSWEAR INC.Trois-Kivières.1962.1966 à/to 1973 incl.BELL HOME OWNERS ASSOCIATION (76TH AVENUE).Stc-Tl.érèse.1963 à/to 1973 incl.BETTER BARGAIN STORE LTD.Montreal.1971 à/to 1973 incl.St-Eu.ile.1972 et/and 1973 LE BISTRO NORMANDIE INC.ARMAND BOISJOLY & FILS LTEE.BOUCHERIE ECLAIR DE LA BAIE INC BOULEVARD GAZ-BAR INC.GABRIEL BOURASSA TRANSPORT INC.BOUTIQUE BALAJELLE LTEE.BOUTIQUE BARON INC.BOUTIQUE DE BLAUSSE INC.BOUTIQUE GEORGIO SHOES LTD.BOUTIQUE DU NETTOYEUR INC.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Port-Alfred.1966 à/to 1973 incl.St-Jean.1966, 1967.1969 à/to '.973 incl.Val d'Or.1972.1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7089 Nom de la compagnie Xame oflht company LA BOUTIQUE ROD-BER INC.BUANDERIE CLAIRE INC.BUCKINGHAM CONSTRUCTION INC.BUFFET LE GRAND DUC INC.C.C.TRANSPORT INC.C.M.G.(VAL D'OR) INC.C.M.R.DISTRIBUTORS INC.C.P.D.LTEE.O.T.C.CADIEUX INC.CAMP DOMAINE DU REVE ENRG.CANADA FIREBIRD RALLY CLUB INC.CANMACK EQUIPMENT LTD.CARLTON SWIMMING POOL.CELTIC INC.CENTRAL ASPHALTE INC.CENTRE D'ESTHETIQUE GUYMAR INC.CENTRE EXPERIMENTAL EN SYSTEMES VISUELS INTEGRES INC.CENTRE D'IMPORTATION ARTISANALE INC.CENTRE INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE INC.CENTRE NATIONAL D'ART INC.LE CHATEAU DE LA BASTILLE INC.CHATEAUGUAY FOOTBALL CLUB.CINQUANTE ARTISTES INCORPOREE.CIRCUIT MT TREMBLANT ST-JOVITE INC.CITY SURPLUS INC.LE CLUB D'ACHAT SEIGNEURIE INC.LE CLUB ARTISTIQUE DES 80.CLUB D'ATHLETISME DE LONGUEUIL.CLUB AUTO FRANCANAC.CLUB AUTO SPORT METROPOLITAIN INC.CLUB AUTO-NEIGE MAGOG INC.LE CLUB D'AUTOS-NEIGE LA CLAIRIERE.CLUB AUTOSPORT DES LAURENTIDES INC.CLUB AUTO-SPORT MCCLAREN DE WARWICK.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1971 à/t.o 1973 incl.Sillcry.1967, 1971 à/to 1973 incl.Hull.1972,1973 Montréal.1972, 1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Val d'Or.1969 à/tn 1973 incl.Montreal.1969 à/'.o 1973 incl.Laval.1967 à/to 1973 incl.St-Raphaël-de-l'Ile 1970 à/to 1973 incl.Bistro Ville St-Georgea.1971 à/to 1973 incl.Longucuil.1P68 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1963 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine.1972.1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Thércse.1970 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Châteauguay.1961.1968.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.St-Jovit*.1964 à/to 1966 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Brossard.1972.1973 Montréal.1972, 1973 Longueuil.1972, 1973 Joliett*.1966 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Magog.1968 à/to 1973 incl.St-Louis-de-France.1969 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1968 à/to 1973 incl.Warwick.1972, 1973 7090 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.106, No.48 Nom de la compagnie Name of the company CLUB D'AVIONS MINIATURES MAURICIEN INC.CLUB D'AVIONS MINIATURES DU QUEBEC METROPOLITAIN INC.CLUB DE BASEBALL LONGUEUIL JUNIOR INC.CLUB CANOE.LE CLUB CABOULOT DE CHICOUTIMI.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE DU FER A CHEVAL.CLUB DU CHERCHE-MIDI.CLUB CHIMO.CLUB COTE APIK.CLUB COUSTEAU.CLUB DE CROQUET D'YPTON ENREG.CLUB DE CURLING D'ARVIDA INC.CLUB DO-MA-HA INC.CLUB L'ECHOPPE DE CHASSE ET PECHE INC.CLUB ECOLE DE PATINAGE ARTISTIQUE DU SAGUENAY INC.LE CLUB DES FINS RENARDS.CLUB FITZGERALD INC.CLUB FLORENTIEN.CLUB LES G-VERTS.CLUB DE HOCKEY FRONTENAC INC.CLUB DE HOCKEY OLYMPIQUE VAL D'OR INC.CLUB INTER CANADA.CLUB JACOB.LE CLUB MINI MOTO DES BOIS INC.CLUB MOTO-NEIGE AMI-BON-COPAIN A.B.C.ST-ALPHON-SE DE ROBRIGUEZ CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE FLEUR DE LYS INC.CLUB PROGRESSIF DE LA RIVE-SUD INC.CLUB DES RAQUETTEURS LE MAISONNEUVE INC.CLUB DE RAQUETTEURS MICHELON INC.CLUB RECREATIF PLATEAU ST-LOUIS INC.CLUB RICHELIEU LUCERNE-AYLMER.CLUB ST-VINCENT.LE CLUB DE SKI AL-PIN DES LOISIRS DE ST-SEBASTIEN DE BOUCHERVILLE LE CLUB SOCIAL DU C.H.V.INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Trois-Rivières.1965 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965 à/to 1973 incl.Longueuil.1968 à/to 1973 incl.St-Georges.1972.1973 Chicoutimi.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Arvida.1971 et/and 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Ste-Anne-des-Monts.1972, 1973 Trois-Rivières.1972, 1973 Village d'Ypton.1966 à/to 1973 incl.Arvida.1971 à/to 1973 incl.Shawinigan.1972, 1973 Québec.1969 à/to 1973 incl.Arvida.1965 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1961, 1962, 1966, 1967 à/to 1973 incl.Si-Janvier.1972, 1973 Val d'Or.1972, 1973 Montréal.1972, 1973 Rivière-du-Loup.1972, 1973 Val d'Or.1968 à/to 1973 incl.Longueuil.1972, 1973 Clermont.1972, 1973 Tracy.1972, 1973 St-Alphonse-de- 1971 à/to 1973 incl.Rodriguez Montréal.1966 à/to 1973 incl.Lévis.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1963, 1966 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1966 à/to 1973 incl.Aylmer.1966 à/to 1969 incl, 1971 à/to 1973 incl.Québec.1932 à/to 1971 incl.Boucherville.1964 à/to 1973 incl.Ascot Nord.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973.105' année.n° 48 7091 Nom de la compagnie JVame of the company\tAdresse Address\tRapports non produits Returns not filed CLUB SOCIAL DES MOOSE DE VAL ST-MICHEL.\tVal St-Michel.\t1963 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 inci.CLUB SOCIAL ET SPORTIF DE L'EST.\t\t LE CLUB SPOREA INCORPORE.\tSt-Théophole du Lac à la Tortue\t1963 à/to 1973 incl.CLUB DE YACHT ET DE SKI DE M AGOG INC.\t\t1962 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.\t\t COCO-BAR (1967) INC.\t\t LES COLONELS DE SALABERRY DE VALLEYFIELD.\tSalaberry-de-Valleyfield.\t LE COMITE DES CITOYENS DE GRANBY INC.\t\t1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.\t\t COMITE DES CITOYENS DE NOTRE DAME DE LA PAIX.\t\t1970 à/to 1973 incl.COMITE D'ETUDE DES SERVICES DE SANTE DE LA VILLE DE LAVAL\t\t1966 à/to 1973 incl.LE COMITE DE LOISIR DES EMPLOYES FORESTIERS DE DOMTAR (DOLBEAU)\t\t1972.1973 COMITÉ DES LOISIRS DE DUHAMEL INC.\tDuhamel.\t1972, 1973 1971 à/to 1973 incl.1972, 1973 1968, 1970 à/to 1973 incl.COMITE DES LOISIRS DE ST-ALBERT LE GRAND.\t\t \t\t COMITE DES LOISIRS DE ST-CHARLES BORROMEE.\tSt-Charles-Borromée.\t LE COMITE DU SECRETARIAT INC.\tCap-de-la-Madeleine.\t1963 à/to 1973 incl.COMMISSION DES LOISIRS DE BAGOTVILLE .\tBagotville.\t1967, 1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.LA COMPAGNIE DES BALLETS DE OUEBEC INC\tQuébec.\t LA COMPAGNIE DE GICLEURS GENERALE LIMITEE.\t\t LA COMPAGNIE DE TRACTEURS ET D'EQUIPEMENT LTEE\tSt-Augustin.\t1967, 1971 à/to 1973 incl.COMPREHENSIVE FA'HTRTTS SYSTEMS T.TD\t\t1969 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1971 à/to 1973 incl.LE COMPTOIR FAMILIAL DE M AGOG INC\tMagog.\t \t\t CONSEIL DE LOISIRS INC .\tSt-Valère.\t1971 à/to 1973 incl.CONSEILLERS EN MATIERE DE COURSES C.M.C.LIMITEE\t\t1969.1971 à/to 1973 incl.\tSalaberry-de-Valleyfield.\t1972, 1973 \t\t1972.1973 \t\t1972, 1973 \tMontreal.\t1966, 1969 à/to 1973 incl.LES COPAINS DE LA SCENE DES LOISIRS DE ST-SEBASTIEN DE BOUCHERVILLE\tBoucherville.\t1965 à/to 1973 incl.CORPORATION DES ETUDIANTS EN SCIENCES DE L'ADMINISTRATION ET DU COMMERCE LTEE\tQuébec.\t1971 à/to 1973 incl.COUNCIL OF HAZZANIM MINISTERS (JEWISH CLERGY) OF GREATER MONTREAL\t\t1964 à/to 1973 incl.\t\t1970 à/to 1973 incl. 7092 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December Ut, 1973.Vol.105, So.48 Nom de la compagnie Same of the company Adresse Rapports non produit» Address Return! not filed St-Hyncintlie.1965.1966, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1972,1973 St-Michel._____ 1960,1963.1964, 1967 à/to 1973 incl.Arthabaska.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1970 à/to 1973 incl.Reauceville.1972.1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Dorion.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.St-Majorique-de- 1968.1971 à/to 1973 Grantham incl.Drummondville.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Rosemont.1965.1967 à/to 1973 incl.L'Abord-à-Plouffe.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1967 à/to 1973 incl.Salaberry-de- 1970 à/to 1973 incl.Valieyfield Jacques-Cartier.1967 à/to 1973 incl.Outremont.1972, 1973 Laval.1968 à/to 1973 incl.Hampstcad.1967 à/to 1973 inc.Montreal.1959, 1962, 1966, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1960, 1965, 1966, 1969 à/to 1973 incl.CRF.DIT DU VER NAY INC CREDIT MAISON NEUVE INC.CUISINE INSTITUTIONNELLE A.S.& CIE LTEE.DA1X BIO-F.NERGETICS INC.DASCAR ASSOCIATION INC.JOHN DAVID ENTERPRISES INC.DE GASPE AVENUE INVESTMENTS INC .LA DEBACLE.JEAN DEMERS LTEE.DESIGN AWARD CHAIRS & FURNITURE MFG.CO.LTD.LE DOMAINE CHAMP D'AZUR INC.DORE, ARCHAMBAULT INC.DORION GARDENS RECREATION ASSOCIATION.DORVAL INDUSTRIAL PARK LIMITED.DOUBLEN SALES INC.LES DRACONS DE FATIMA.DRUMMOND SPEEDWAY INC.DRUMMONDVILLE HAUL-AWAY INC.DRUMMONDVILLE LEASEHOLDS LTD.DUBE & POMERLEAU CONSTRUCTION LTEE.PAUL & JACQUES DUBOIS ENTREPRISES DE CONSTRUCTION LTEE W.DUBOIS LTEE.DUBUC AUTO LTEE .GUSTAVE DUBUC INC.DUFFERIN DISPOSAL & SERVICE INC.JACQUES DUFRESNE INC.RAYMOND DUFRESNE INC.MARIO DUGRE LTEE.DUKIN ENTERPRISES LTD.DUMFRIES INVESTMENT CORP.GERARD DUMOULIN INC.DUNCAN INVESTMENT CORP. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année.n° 48 7093 Nom de la compagnie Same of the company DUPAC PROMOTIONS LIMITED.GASTON DEPUIS INC.DURAND & FILS LTEE.GEO KG ES H.DURAND LTEE.D'URFE PLAZA INC.DUVELAN CO.LTD.DYNCO MANAGEMENT CORP.EAGLE PAVING CO.LTD.EASTERN TOWNSHOP WELDING INC.EAST-HAVEN LAND & HOUSING CORP.ECHANGE ET VENTE DE CHEVAUX DU QUEBEC LTEE ECHO HOLDING CORPORATION.ECLAIRAGE TECHNIQUE (CANADA) LTEE.LES ECLAIREURS LOUIS-JOLIET INC.ECO INC.ECOLE DE BALLET DE SEPT-ILES INC.EDCO CONSTRUCTION CO.LTD.EDGEMORE HOLDINGS CORP.LES EDIFICES FERVAIN INC.LES EDIFICES SEPT-ILES INC.LES EDITIONS MONDANBAULT INC.ELEGANCE MATERNITY WEAR CO.ELEGANT BARBER SHOPS LIMITED.ELEVEN FIFTEEN REALTY CORP.ELMAN SNACK BAR INC.LES EMPLOYEURS FORESTIERS DE LA BAIE DES CHALEURS INC.LES ENFOUISSEMENTS SANITAIRES DU QUEBEC INC.ENRICO NEW AND USED AUTO SALES INC.L'ENTREPRISE DES ARTISANS LTEE.LES ENTREPRISES D'ARTS CULTURELS DE MONTREAL INC.LES ENTREPRISES BAREL INC.LES ENTREPRISES BASQUES INC.LES ENTREPRISES BAUR AU LAC LTEE Adre\u2014c Rapports non produits Addren Returns not filed Montreal.1966'à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Émélie-de- 1972, 1973 l'Énergie Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal .1971 à/to 1973 incl.Ville St-Michel.1964 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Fabreville.1966 à/to 1973 incl.Sept-Ilcs.1970 à/to 1973 incl.LaSalle .1970 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1971 à/to 1973 incl.St.-Anselmc.1968, 1971 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1966.1968 à/ti.1973 incl.Trois-Rivières.1968 à/to 1973 incl.Québec.1972, 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Ville Lasalle.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl. 7094 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company LES ENTREPRISES BRI-AY INC.LES ENTREPRISES GERARD ROBIDOUX INC.LES ENTREPRISES GERLE INC.LES ENTREPRISES GIMAR INC.ENTREPRISES INTERNATIONALES J.B.C.LTEE.LES ENTREPRISES L.DURANCEAU LTEE.ENTREPRISES PAUL GIGUERE INC.LES ENTREPRISES R.B.INC.LES ENTREPRISES SPECO INC.ETROPAL 1966 INC.EUROCAN FURNITURE INC.EUROPEAN ARTISTIC WOODCRAFT INC.EUROPEAN BAZAAR (STE-THERESE) LTD.EUROSTEEL CORP.EVALUATIONS ARSENAULT INC.EXPRESS ARTS GRAPHIQUES INC.LES FABRICANTS DE PISCINES ET DE VINYL EAU-CLAIRE LIMITEE LA FANFARE DE FARNHAM INCORPOREE.FARNHAM TIRE & AUTO SUPPLY LTD.FEDERATION DES LIGUES DU SACRE-COEUR DIOCESE DE HAUTERIVE LA FEDERATION DES OEUVRES DE CHARITE DE ST-ANTOINE DE LONGUEUIL FEDERATION DE VOLLEY-BALL DU QUEBEC.LA FERME AZUR INC.LA FERME STE-LOUISE LTEE.FILIAULT AUTO BODY.INC.FISHER TRANSPORT LTD.FORM TOOLS (QUEBEC) INC.REMI FORTIN INC.FOYER DE GATINEAU INC.FOYER ST-EUSEBE INC.FOYER ST-RAPHAEL INC.FRASORT ENTERPRISES LTD.G.& H.DANCERS LTD.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.19'0 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Drummondville.1967, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1961, 1962, 1971 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1964, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Longueuil.1970 à/to 1973 incl.Ste-Anne-des-Monts .1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Ste-Foy.1966, 1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Farnham.1963, 1969 à/to 1973 incl.Farnham.1964 à/to 1973 incl.Hauterive.1967, 1969 à/to 1973 incl.Longueuil.1972 et/and 1973 Montréal.1972 et/and 1973 St-Félicien.1968 à/to 1973 incl.Ste-Béatrix.1964, 1965, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.St-Michel.1970 à/to 1973 incl.FortCoulonge.1972 et/and 1973 Gatineau.1970 à/to 1973 incl.Princeville.1966, 1966.1971 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1968 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n\" 48 7095 Nom de la compagnie Name of the company GARAGE I.v M AUTO REPAIR INC.GENERAL ASTISTS CONSULTANTS LTD.GENICOM INC.GEOPROBE (QUEBEC) LTD.GESFICO INC.GESTION BORONAT LTEE.GIANT BACHELOR MINES LTD (NO PERSONAL LIABILITY) LEOPOLD GIARD LTEE.GILBERT INDUSTRIAL PAINTING LTD.GILBERT & LAFRENIERE INC.M.GILBERT LIMITEE.GILBERT TRAVEL AGENCY (MONTREAL) LTD.NOEL GIRARD INC.R.GIRARD AUTO LTEE.Y VAN GIRARD ET ASSOCIES INC.GLAMORTIZING DRY CLEANING & SHIRT LAUNDERERS INC.GOR-BA CO.LTD.GRAND BAHAMA PROPERTIES CORP.GRENIER CHALIFOUX & ASSOCIES INC.ARTHUR GROLEAU ET FILS INC.GROUPE BBB LTEE.H.D.L.S.(1963) LTEE.HALDON ENTERPRISES INC.ARTHUR HALLE ENTERPRISES INC.HARTLEY BARBER LIMITED.HERITAGE FINE ARTS LTD.HOTEL BAIE COMEAU INC.HOTEL BELVEDERE LIMITEE.ANDREW HRIPKO INC.LES IMMEUBLES BARAN LTEE.LES IMMEUBLES BARBEL INC.LES IMMEUBLES BAUDELAIRE INC.LES IMMEUBLES DU COLLEGE LTEE.LES IMMEUBLES DORVAN INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Verdun.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Granby.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1962 incl.1968.1971 à/to 1973 incl.Boucherville.1966, 1967, 1972 et/and 1973 Ste-Catherine-d'Alexan- 1970 à/to 1973 incl.drie-de-la-Prairie Ste-Thérèse.1971 à/to 1973 incl.Beauceville.1971 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Beloeil.1969 à/to 1973 incl.Rouyn.1960.1967 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.St-Lambert.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Michel.1969 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1970 incl., 1972 et/and 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Monterai.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Baie Comeau.1964.1968 à/to 1973 incl.Matane.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1969 à/to 1973 incl.Gagnon.1964 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Ste-Anne-de-Bellevue.1960, 1966, 1967, 1971 à/ to 1973 incl.Ste-Foy.1962 à/to 1973 incl. 7096 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.106, No.1,8 Nom de la compagnie Name of the company IMMEUBLES DURIGHA INC.LES IMMEUBLES QUEBECOIS INC.IMMEUBLES ROLAND DUMAIS INCORPOREE.LES IMPORTATIONS GEMINI INC.INDEX ECLAIR DE VOTRE QUARTIER INC.INDUSTRIAL COATINGS (QUEBEC) LTD.LES INDUSTRIES SOPEX INC.INTERCONTINENTAL BARGAIN STORE LTD.INTERNATIONAL STRETCH LTD.INTERPROVINCIAL DREDGING COMPANY LIMITED.INTER-PROVINCIAL ELECTRONICS LTD.INVENTIONS INTERNATIONALES DUCHESNE LTEE.LES INVESTISSEMENTS RIMOUSKI INC.INVISIBLE ART WEAVERS LIMITED.J.J.BAR SALON INC.JEUNE CHAMBRE AYLMER-LUCERNE INC.LA JEUNE CHAMBRE DE ST-APOLLINAIRE INC.LE JEUNE COMMERCE DE LA TUQUE INCORPOREE.LES JEUNES SPORTIFS DE LA CITE DE JACQUES CARTIER.JEUNESSES DYNAMIQUES D'ASBESTOS.JIM & NICK SNACK BAR INC.JOURNAL CONSTRUCTO INC.JOURNAL CONSTRUCTO (19G7) INC.LES JOUVENCELLES DE JOLIETTE.LES JOYEUX CAVALIERS INC.LES JOYEUX LUTINS DE JONQUIERE KENOGAMI INC.JUL-SAN ENTERPRISES INC.KARDIN OF MONTREAL LTD.KAY MICK ENTERPRISES LTD.KEBCAN ENTERPRISES INC.KIDDIE LAND NURSERY & BABYSITTING SERVICE INC.KORD ENTERPRISES LTD.L.& N.INVESTMENT COMPANY INC.LABORATOIRE DU DOCTEUR LAMBERT INC.GILLES LA POINTE AUTOMOBILE LTEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Jean.1964.1965.1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Bnucherville.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1961, 1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Québec.1963, 1964, 1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.La Tuque.1972 et/and 1973 Rimouski.1962, 1972 et/and 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Aylmer.1967 à/to 1973 incl.St-Apollinaire.1972.et/and 1973 La Tuque.1964 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1965, 1966.196S à/to 1973 incl.Asbestos.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1971 à/to 1973 incl.Joliette.1966 à/to 1973 incl.Arvida.1970 à/to 1973 incl.Jonquicre.1963.1970à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1957 à/to 1973 incl.Yamaska.196S, 1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7097 Nom de la compagnie Name of the company LES LAURENTIENNES, CORPS DE CLAIRONS FEMININ.LAVAL HOT BAGEL BAKERY, GROCERY & DELICATESSEN LTD.LAVOMATIC INC.GILLES LECLAIR MAINTENANCE INC.LEITHMAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED.LEO BAR-B-Q INC.JOSH LIBBEN ENTERPRISES INC.LIGUE DE BASEBALL DU QUEBEC INC.LA LIGUE DES CITOYENS DE GRAN'DM ERE INC.LIGUE DES CITOYENS DE LA PAROISSE DE STE-ODILE CITE DE QUEBEC INC.LIGUE CITOYENS ST-HUBERT COMTE DE TAILLON INC.LIGUE DES CONTRIBUABLES DE LA CITE DE SOREL INC.LIGUE DE HOCKEY MINEUR DE DRUMMONDVILLE INC LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-GERARD MAGELLA INC.LE LION D'OR, ANTIQUITE ET CASSE-CROUTE LTEE.LITCHFIELD ENTERPRISES LIMITED.LOCATION D'APPAREILS MENAGERS LAFLECHE INC.LOGO GARMENT LTD.LES LOISIRS DE BOUCHERVILLE INC.LES LOISIRS DE LES ECUREUILS INC.LES LOISIRS DU LAC DES ARTISTES LYDIA GARDEN.LES LOISIRS DE ST-BRUNO INC.LES LOISIRS DE ST-GERARD (WOLFE) INC.LOISIRS ST-JOSEPH INC.LOISIRS ST-PIERRE & PAUL DE DRUMMONDVILLE INC.LORD-DES - ROCHERS INC.LORETTE AUTOS LAVAGE INC.LOTAPARC INC.LUJE ENTERPRISES LTD.M.F.AUTOMARK INC.MADELU INC.MADISON DEVELOPMENT CO.LTD.MAGASIN LE BATEAU INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.19fi2, 1971 à/to 1973 incl.Laval.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972, et/and 1973 Brossard.1972, et/and 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Frand'Mère.1966, 1968 à/to 1973incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.St-Hubert.1972.1973 Sorel.1969 à/to 1973 incl.Drummondville.1970 à/to 1973 incl.St-Gérard Magella.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Hull.1967 à/to 1973 incl.Laflcche.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Boucherville.1949 à/to 1951 incl.1953 à/to 1963 incl.1970 à/to 1973 incl.Les Ecureuils.1965, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968, 197! à/to 1973 incl.St-Bruno.1948 à/to 1973 incl.St-Gérard.1967, 1970 à/to 1973 incl.Hull.1964 à/to 1973 incl.Drummondville.1969 à/to 1973 incl.St-Michel.1965, 1966, 1969 à/to 1973 incl.Loretteville.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1967 à/to 1973 incl.St-Lambert.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl. 7098 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st.1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Neuville.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1958 à/to 1968 incl., 1973 Saint-Lambert.1965 à/to 1973 incl.Drummondville.1960, 1963 à/to 1973 incl.Hauterive.1967 à/to 1973 incl.Montréal.I960 à/to 1962 incl.1965 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1968.1969, 1973 Montréal.1965, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1966 à/to 1973 incl.Victoriaville.1969, 1972, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Mont-Royal.1968, 1972, 1973 Montreal.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1965 à/to 1973 incl.Shawinigan.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1968, 1971 à/to 1973 incl.St-Emile.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 inèl.Fabreville.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Baie-Comeau.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Lasalle.1971 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1972 et/and 1973 Montréal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Valcourt.1971 à/to 1973 incl.Beloeil.1972 et/and 1973 Laval.1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1973 MAGIC ELECTRO-WAV ENTERPRISES LTD.MAGIC SLIPPER CO.OF CANADA LTD.LA MAISON DE L'EDUCATION MADEC DU QUEBEC INC.MAISON NAPOLEON INC.LA MAISON DU SPORTSMAN INC.LES MAJORETTES DE DRUMMONDVILLE INCORPOREE.MANIC ELECTRONIQUE INC.LES MANOIRS D'ARESVILLE LTEE.LE MARCHE C.-H- DUBE LTEE MARCHE DUSSAULT INC.GAIL MARTIN & ASSOCIATES INC.MASTERCRAFT ENTERPRISES LTD.GERMAIN MERCIER AUTOMOBILES INC.METROPOLE OFFICE & SPORT EQUIPMENT LIMITED.MEUNIER, DUBREUIL.MEUNIER & ASSOCIES INC.MIGNONNETTES ROYALES INC.MONDEX FILMS LTEE.NICOLE MONGEAU & ASSOCIES LTEE.MONTREAL SPORTSERV1CE LIMITED.THE MONTREAL STAGE COMPANY.MOTEL AMI-AMI LTEE.MOTORICIE INC.LE MOUVEMENT CIVIQUE DE ST-LAURENT.MUR-AVI INC.MYSTIQUE-ART INC.NADON GAS BAR AND PETROLEUM LTD.NATCO LTD.NETTOYEUR BAIE COMEAU INC.NEW BREAM LOUNGE BAR INC.NEW MORTON INVESTMENTS LTD.90TH AVENUE RESTAURANT INC.NORTH WOOD ESTATES INC.L'OASIS (MONTREAL).L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE VALCOURT.OMNI-PRIX LIMITEE.L'OPTIQUE LAVAL, LTEE.PANFORT INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1973.105' année, »° 48 7099 Nom de la compagnie Same of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed EDGAR PARENTEAU LTEE.LA PATISSERIE SUPERBE INC.ARTHUR PELLETIER & FILS.LIMITEE.LOUIS-GEORGES PERRON INC.LA PETITE LIGUE DE BASEBALL DE VALLEYFIELD INCORPOREE LES PETROLES STRATO (1961) INC.PIE IX SILKS A DRAPERIES INC.LES PLACAGES OUTAOUAIS LTEE.LES PLACEMENTS D'ARGENTEUIL LIMITEE.LES PLACEMENTS ARTI INC.LES PLACEMENTS LE DUC INC.LES PLACEMENTS G.R.E.C.LIMITEE.LES PLACEMENTS IMMOBILIERS DUVERCO.LES PLACEMENTS J.C.L.M.INC.LES PLACEMENTS SOLVA INC.LES PLACEMENTS VILLE-MARIE LIMITEE.LA PLOMBERIE R.LEGARE A FILS LTEE.POIRIER A ST-ARNAUD INC.LA POUPONNIERE D'YOUVILLE INC.PRESCOTT METAL WORKS CO.LTD.PRESTIGE DEVELOPMENT LTD.PRET D'HONNEUR DE L'ECOLE SUPERIEURE ST-GEOR-GES D'IBERVILLE PRODUCTIONS \u2022 ENTRE LA MER ET L'EAU DOUCE » INC.LES PRODUCTIONS SOLFEGE INC.LES PRODUCTIONS SPEX LTEE.PRODUITS AVICOLES POULIN INC.LES PRODUITS FORESTIERS ASHBURTON INC.PROVISIONS P.M.C.LIMITEE.PUB D'ARMES INC.PYRAMIDUM INC.QUEBEC FEMININE ARTS INC.QUEBEC OIL REFINERY LTD.QUEBEC SPORTSERVICE INC.Chambly.1966, 1969 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965.1966, 1967.1969 à/ to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1971 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1965 à/to 1973 incl.Matane.1961.1964, 1966, 1970 à/ to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Ayersville.1964.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967.1968.1969, 1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1970 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles.1970, 1972 et/and 1973 Anjou.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Anjou.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1970 à/to 1973 incl.Longueuil.1972 et/and 1973 Amos.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1965.1967 à/to 1973 incl.Iberville.1967.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Notre-Dame-des-Pins .1965, 1966 1968 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Rosaire.1972 et/and 1973 Austin.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl. 7100 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed R.& H.ENTERPRISES LTD.Montreal.1968 à/to 1973 incl.R.M.R.SALES AGENCY LTD.Montreal.1968 à/to 1973 incl.RADISSON RESTAURANT INC.Montreal.1965 à/to 1973 incl.RAPID MAINTENANCE INC.Montreal.1966 1968 à/to 1973 incl.REGENT GAS BAR INC.Montreal.1965 à/to 1973 incl.RESTAURANT AU FIN GOURMET ASBESTOS INC.RESTAURANT BARBEL (1965) LTEE.LE RESTAURANT L'ORGUE LTEE.RIGAUD INVESTMENTS LTD.RIVER DRIVE HOUSING & LAND CORP.LE RIVIERA INC.ROBERT BAR SALON INC.ROCHESTER MISTER EASE INC.J.GEORGES ROULEAU ET ASSOCIES INC.ROUNDALOWS SNACK BAR CORP.ROYAL ELECTRONICS INC.S.O.S.DRYWALL INC.GERARD ST-GERMAIN LIMITEE.ST-JEAN DRIVE YOURSELF INC.ST-JEROME AVIATION LTEE.ST-MAURICE FUEL ECON-O-MIZER INC.STE-FOY SNACK BAR INC.SALLE D'ACCUEIL DOMREMY BUCKINGHAM INC.SALON CLAIRE GAGNON LTEE.SALON ELEGANT LTEE.SAMSON INVESTMENT CO.INC.SCHUSTER & SCHIFF FURS LTD.SCIERIES VAL-ST-GILLES LTEE.SEAGULL PORK CO.LTD.LE SECRETARIAT DES SYNDICATS NATIONAUX DE DRUMMONDVILLE INC.SECURITE ET INVESTIGATION G.P.INC.SERVICES METROPOLITAINS S-T INC.Asbestos.1972 et/and 1973 Gagnon.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1965 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.St-Georges-de-la Rivière-Bleue 1965 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1970 à/to 1973 incl.St-Michel.1966.1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1967 à/to 1973 incl.Dolbeau.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Michel.1966 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Mackayville.1966 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl Buckingham.1963 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Grande Rivière.1966, 1968 à/to 1973 incl.Duvernay.1964 à/to 1973 incl.Chomedey.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Ottawa.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Druinmondville.1968 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964, 1967 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, a\" 48 7101 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed SHERBROOKE JAYCEES.SHIRLEY'S RESTAURANT (1963) INC.SILVERMAN INVESTMENTS LTD.B.SINGER REALTY LTD.SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DE SHERBROOKE.LA SOCIETE CANADIENNE DE L'OUIE DU QUEBEC.LA SOCIETE D.S.LIMITEE.SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE BAIE-COMEAU____ LA SOCIETE DE RECHERCHES EN TELESYSTEMES- LA SOCIETE ST-JEAN BAPTISTE DE LA PAROISSE DE ALBERTVILLE LA SOCIETE ST-JEAN BAPTISTE DE LA PAROISSE DE ST-CHARLES GARNIER LA SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE DE ST-HONORE.SOCIETE SAINT-JEAN BAPTISTE DE SAINTE-ROSALIE.SOFEX INC.SOFOBEC LTEE.SOGA INC.SOGENEX INC.SOGICAN INC.SOGNO INC.SOLING INVESTMENT CO.LTD.SOLOCAT INC.SOREL DEVELOPMENT CORPORATION.SOUVENIR BARBER SHOP INC.SPEAR INVESTMENT LTD.STANDARD CREDIT & LOAN CORPORATION.STANFORD INVESTMENT LTD.STANLEY TOWERS INC.STAR PACKING CO.LTD.STARLIGHT TRADING CORP.STATION DE SERVIVE DUHAMEL LTEE.STATUE REALTY CORP.STEADY REALTIES INC.Sherbrooke.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1967, 1970.1971 et/and 1973 Montreal.1964,1969,1973, Montreal.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1970 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 inci.Baie-Comeau.1965 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Albertville.1955.1971 à/to 1973 incl.St-Charles-Garnier.1957.1971 à/to 1973 incl.St-Honoré.1957, 1959, 1972 et/and 1973 Ste-Rosalic.1960, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Joliette.1965, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1968 à/to 1973 incl.Verdun.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1961 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Mount Royal.1963 à/to 1973 incl.Côte St.Luc.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl. 7102 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 1st.1973.Vol.105.No.48 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed STEBRO AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.STEDRY INVESTMENTS LTD.STEMIC LTD.STEREO ARTISTIQUE INC.STONEHAM STATION DE SERVICE INC.STUDIO ARISTOCRATE INC.STUDIO DES ARTISTES CANADIENS INC.STUDIO DE SANTE SILHOUETTE DE DUVERNAY LTEE.STYLE WISE FASHIONS LTD.SUD LTEE.SUGERMOR HOLDINGS INC.SUN AUTOMATIC PARKING INC.SUNSHINE GARDEN DEVELOPMENT CORP.SUNSHINE REALTY LTD.SURWIN INVESTMENTS LIMITED.SYMBOL FURNITURE CO.LTD.T.S.D.CONSTRUCTION LTEE.TAB SERVICE STORES LTD.TAB TOP LIMITED.TAMAR INC.TAPIS COMMERCIAL INC.TAPIS NET INC.TAVERNE CALURON INC.TELA ELECTRIC SYSTEMS LTD.THEATRE DU GESU INC.THEATRE DE L'OUEST QUEBECOIS.THERIAULT AVIATION (QUEBEC) LTD.TIMES SQUARE CAFE INC.LES TITANS DE SOREL INC.TORONADO BAR LOUNGE INC.LES TRAITEMENTS DU BAS ST-LAURENT INC.TRI-TAB OF CANADA LTD.TROIS-RIVIERES AUTO CLUB INC.U.S.CONSTRUCTION CO.LTD.Lachine.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Laval.1968 à/to 1973 incl.Stoneham.1959 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1964, 1965.1969 à/to 1973 incl.Québec.1963,1972.1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1958.1959.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1966, 1967, 1971 à/to 1973 incl.Laflèche.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1961.1970.1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Lasalle.1963, 1965 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1973 Laval.1966.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Rouyn.1964 à/to 1973 incl.Dorval.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1964 à/to 1973 incl.Sorel.1968 à/to 1973 incl.St-Michel.1969 à/to 1973 incl.Rimouski.1972, 1973 Beaconsfield.1966.1967, 1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1907 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7103 Nom de la compagnie Name of the company\tAdresse Address\tRapports non produits Returns not filed \t\t1962, 1970 à/to 1973 incl.\t\t1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1960.1962 à/to 1973 incl.1969, 1971 à/to 1973 incl.1972,1973 1966 à/to 1973 incl.1964.1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.\t\t VAL SENNEVILLE LUMBER AND TIMBER LTD.\tVal d'Or.\t A.VANIER OF CANADA LTD.\t\t VARIETES GILLES LANGLOIS INC.\t\t VEILLET & CIE LTEE.\t\t VETEMENTS ETON (1964) LTEE.\t\t LES VETERANS DE L'ARMEE.LA MARINE ET DE L'AVIATION AU CANADA UNITE 367 CHAMBLY\t\t GERARD VIDAL TRANSPORT INC.\t\t1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.LES VIF-ARGENT.\t\t VOYAGES BARBET TOURS INC.\t\t WEBER BASE METAL MINE INC.(NO PERSONAL LIABILITY)\t\t THE YELLOW SUBMARINE SANDWICH BARS LTD\t\t1969 à/to 1973 incl.1966, 1970 à/to 1973 incl.YORK OFFICE SUPPLY CO.LTD.\t\t \t\t Le directeur du service des compagnies, 54S65-o Pierre Desjardinb.\tPierre Desjardinb, 54865-0 Director of the Companies Service.\t Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives\tDepartment of Financial Institutions, Companies and Cooperatives\t Lettres patentes (1 \" partie)\tLetters Patent (Part 1)\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t Nom / A'ame\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date \t\t CHARPENTE D'ACIER INDUSTRIELLE A.M.P.INC.\t\t AI.TP.Tt'R INDUSTRIAL FURNITURE CO LTD\t1R70 T~>;iviHsnn Montréal\t LA COMPAGNIE D'AMEUBLEMENT INDUSTRIELLE ALTED LTEE.\t\t \t\t.04 10 73 J.L.ALUMINUM INC.\t\t CREATION ANGELINE INC.\t.265 Port Royal Street, Montreal.19 10 73\t 7104 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom / Same Siège social / Head Office Incorporation Date ANNIT LIMITEE .ANNUC LIMITED.AQF.M LTEE AQEM LTD.AUTO ELECTRIQUE MENARD INC.MENARD AUTO ELECTRIC INC.AUTO G.V.INC.G.V.AUTO INC.AUTO MEILLEUR LTEE.AVIAMATIC INDUSTRIES INC.INDUSTRIES AVIAMATIC INC.fl.7\".FINANCIAL SERVICES LTD.8ERVICE8 FINANCIERS B.T.LTEE.B.T.SECURITIES LTD.LES VALEURS MOBILIERES B.T.LTEE.LE BAR FANTASIA INC.FANTASIA BAR INC.BAR SALON LE PETIT BOURG INC.BETON THERMOSPAN INC.THERMOSPAN CONCRETE INC.LES BRASSERIES JOLIETTE INC.CARO INVESTMENT LIMITED.INVESTISSEMENTS CARO LIMITEE.LE CENTRE CAPILLAIRE ROBERT INC.CENTRE DE SKI DE BAIE ST-PAUL (1973) INC.CENTRE DE SPORTS DE PLEIN AIR T.O.S., TERRASSE VAUDREUIL INC.T.O.S.OUTDOOR CENTER.TERRASSE VAUDREUIL INC.CERCUEILS BERNIER INC.BERNIER CASKETS INC.CHABY INC.CHAMBLY WIRE WORKS INC.LES FILS METALLIQUES CHAMBLY INC.CLUB CAPRICORNE INC.CLUB DE HOCKEY LES BOMBARDIERS DE ROSEMONT INC.LA COMPAGNIE D'AMENAGEMENT & RECREATION ESCAPADE LTEE.ESCAPADE RECREATION & DEVELOPMENT COMPANY LTD.LA COMPAGNIE ASPIRA SUPERIEURE LTEE.LA COMPAGNIE DE COFFRAGE DAWE LTEE DA WE FORMWORK COMPANY LTD.LA COMPAGNIE HELART LTEE.CONSTRUCTION DOMPAT INC.DOMPA T CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION R.GODIN INC.R.GODIN CONSTRUCTION INC.6246.Esplanade Street, Montreal.24 10 73 Beloeil.17 09 73 Lnprairie.25 10 73 10600, boulevard St-Laurent, Montreal 22 10 73 Mont-Laurier.09 10 73 4968.des Grandes Prairies Boulevard.06 11 73 Saint-Léonard.1155.Dorchester Boulevard West.22 10 73 Suite 3900, Montreal.1155.Dorchester Boulevard West.22 10 73 Suite 3900, Montreal.217-219 Laurier Street West, Montreal 29 10 73 107, rue St-Charles ouest.Longueuil.07 11 73 Montréal.11 10 73 Joliette.29 10 73 1669 Ringuet Street, apt.306, Saint- 04 10 73 Bruno.230, boulevard Harwood.Dorion.21 09 73 Baie Saint-Paul.08 11 73 121, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil, 10 10 73 Vaudreuil.Saint-Edouard-de-Lotbinière.31 10 73 7702, rue A vrille, Anjou.22 10 73 2956.chemin Ste-Thérèse, Carignan.15 10 73 37.rue Notre-Dame.Cap-Chat.28 09 73 Montréal.16 10 73 Braeside Avenue, Hudson.22 10 73 Laval-des- Rapides.16 10 73 Montréal.ig io 73 269, 5e Avenue, Iberville.22 10 73 5806, rue Maricourt, Saint-Léonard.09 10 73 1148, Place Montcalm, Saint-Bruno-de- 26 09 73 Montarville. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1973.105' année, a\" 48 7105 Incorporation Nom / Xame Siège social / Head Office Date CONSTRUCTION THEBERGE & FRERE INC.\tSaint-Hubert.\t14\t08\t73 LES CONSTRUCTIONS A.G.R.CAP-CHAT INC.\tCap-Chat.\t11\ton\t73 \t\t30\t10\t73 \t2920.boulevard St-Anicet, Bagotville.\t12\t10\t73 LA CORPORATION DE MACHINE A TRICOTER CONTINENTAL LTEE.CONTINENTAL KNITTING MACHINE CORP.LTD.\t171 Poplar Drive, Dollard-des-Ormeaux\t02\t11\t73 COUTURE B.J L.INC .\t\t01\t10\t73 CREDIT REITRAC INC\t\t26\t10\t73 CUTRONA dt ASSOCIATES.GENERAL CONTRACTORS INC.CUTRONA & ASSOCIES, ENTREPRENEURS GENERAUX INC.\t\t16\t11\t73 \t1472, rue Crescent, Montréal.\t03\t10\t73 \t\t26\t10\t73 BUDGET DECOR OF QUEBEC INC.\t\t\t\t EXCAVATION C.DESCHAMPS INC.\t420, Fleur de Lys, Repentigny.\t19\t09\t73 DISTRIBUTION ET RECHERCHE AUDIO-VISUELLE (D.R.A.V.) INC.\t3170.Edouard-Montpetit, app.14, Montréal 250.\t10\t07\t73 \tJoliette.\t16\t11\t73 AUTOMOBILES DRAINVILLE INC.\t\t\t\t \t\t22\t10\t73 T ICI NO STABLES INC.\t\t\t\t Ï.FS F.NTRF.PRTSFS DFSROCHERS it- SIMARD INC\t\t26\t10\t73 \tMontréal.\t17\t10\t73 LES ENTREPRISES G R .1 LTEE\t\t18\t10\t73 T.ES ENTREPRISES fïTTV POISSON INC\t\t18\t10\t73 \t10, rue Pie XII, Beauport.\t22\t10\t73 LES ENTREPRISES LUCIEN GOYETTE INC.\t107,4e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil.\t11\t10\t73 \t1035, rue Beaugrand, Acton Vale.\t18\t10\t73 NOTCA ENTERPRISES LIMITED.\t\t\t\t ire FTJTRFPRIRFR RAYPROC INC\t\t19\t10\t73 RAYPROC ENTERPRISES INC.\t\t\t\t FNTRFTTFV fi F RATISSES l\\AKESHORE INC\t\t03\t10\t73 LAKESHORE BUILDING MAINTENANCE INC.\t\t\t\t EURO INVESTMENTS 'QUEBEC) LIMITED.LES PLACEMENTS EURO (QUEBEC) LIMITEE.\t1203, IBM Building, 5, Place Ville Marie, Montréal,\t06\t11\t73 EXCAVATION NORMAND BEAUREGARD INC.NORMAND BEAUREGARD EXCAVATION INC.\t23lê, boulevard St-Henri, Mascouche.\t09\t10\t73 \t4115.rue Sherbrooke ouest, suite 310.Westmount.\t21\t08\t73 I A FFRMF HVPO TNC\t\t05\t11\t73 HYPO FARM INC.\t\t\t\t LES IMMEUBLES FLORIDEV INC.\t1203, IBM Building, 5, Place Ville Marie, Montréal 113.\t22\t10\t73 7106 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Nom .' Some Siège social / Head Office Incorporation Date FONDERIE D'ART VANDEVOORDE INC.VANDEVOORDE ART FOUNDRY INC.HENRI FONTAINE LTEE.LES FORMES B.S.T.INC.FOURRURES A.JODOIN & FILS INC.O.K.A.SERVICE STATION INC.STATION SERVICE C.K.A.INC.GARACON INC.GARAGE B.JUTRAS INC.OARAGE JOS MARTIN ET FILS INC.GARAGE LIONEL NADEAU INC.GENEREUX & PERODEAU INC.GESTION MARGUERITE INC.MARGUERITE HOLDING INC.GESTION REGICAR LTEE.LE GUIDE DE PREVENTION DES INCENDIES DU QUEBEC INC.H.E.HARBEC INVESTMENT INC.LES PLACEMENTS HE.HARBEC INC.LES IMMEUBLES D.M.D.INC.LES IMMEUBLES RAYMOND BEDARD LTEE.LES IMMEUBLES ROCK LTEE.ROCH PROPERTIES LTD.LES IMMEUBLES ST-BASILE INC.LES IMPORTATIONS MOULAND LTEE.MOULAND IMPORTS LTD.LES INDUSTRIES BERTRAND MORIN INC.BERTRAND MORIN INDUSTRIES INC.LES INDUSTRIES LUBEC INC.LUBEC INDUSTRIES INC.LES INVESTISSEMENTS COLANRO DE SEPT-ILES INC____ INVESTISSEMENTS KANATA INC.KANATA INVESTMENTS INC.J.B.GRAPHICS INC.LES GRAPHIQUES J.B.INC./.* /.LEISURE PROPERTIES LTD.LES IMMEUBLES DU LOISIR J.& J.LTEE JOKER IMPORTS LTD.LES IMPORTATIONS JOKER LTEE KAREN DALE MANAGEMENT INC.ADMINISTRATION KAREN DALE INC.KAY INVESTMENTS GROUP INC.LE GROUPE D'INVESTISSEMENTS KAY INC.KERAMI INC.2310.rue Ste-Marguerite, Longueuil .22 10 73 Magog.02 11 73 Montréal.26 09 73 355, rue St-Georges.Laprairie.12 10 73 7900, St-Denis Street, Montreal.25 09 73 1582, chemin St-Louis, Québec 6.11 10 73 1317, boulevard Labelle, Blainville____ 06 11 73 1939, boulevard Hamel, Duberger____ 26 10 73 2800.6e Avenue, Saint-Georges-Ouest.18 10 73 Saint-Cyrille.18 10 73 38.rue Adelaide, Candiac.06 10 73 Montréal.17 09 73 5958, St-Hubert, Montréal.26 07 73 129, rue Rodrigue, G ran by.10 09 73 754, des Mélèzes, fl, Sainte-Foy.09 11 73 590, rue Racine, Loretteville.26 10 73 2360 Lucerne Road, Mount Royal.02 II 73 Saint-Basile.14 11 73 8290 Arthur Buies Street, Montreal.15 10 73 Rock Forest.16 10 73 100 Harwood Boulevard, Place St.29 10 73 Charles, Suite 3, Dorion.Sept-Iles.24 10 73 Montreal.24 10 73 2050 Mansfield Street, 12th Floor, 24 10 73 Montreal.c/o C T Corporation System (Canada), 27 08 73 LTD., 220 Grande-Allée East, Québec.5 Abitibi, Place Bonaventure, Mont- 05 10 73 real.251 Stillview, Pointe Claire.28 09 73 5425 Casgrain Street, Montreal.12 10 73 Cap-Chat.21 lo 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7107 Nom ' Name Siège social / Head Office Incorporation Date L.P.H.MODULOR INC.MODULOR L.P.H.1XC.GILLES LAFRANCE INC.JACK LEIBY LTEE.JACK LEIBY LTD.LOUISE LIMOGES INC.LOCATION THEBEX INC.THEBEX LEASING INC.LOCATIONS TRANS-QUEBEC INC.TRANS-QUEBEC RENTALS INC.MAINTENANCE INGETEC INC.MAISON MOBILE MILLE ISLES INC.MANUFACTURE DE MEUBLES ETOILE LTEE.STAR FURNITURE MANUFACTURING LTD.DAVID MARSHALL DRESS INC.ROBES DAVID MARSHALL INC.MENARD & GAGNON INCORPOREE.OUTILS DE COUPE UNIVERSELLE INC.UNIVERSAL CUTTING TOOLS INC.PANDECOR INC.PAT ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES PAT LTEE.PATY SHOP LTD.BOUTIQUE PATY LTEE PIERREFONDS GARDEN RESTAURANT INC.RESTAURANT DU JARDIN PIERREFONDS INC.PISCINES FAMILIALES RIVE SUD INC.PITT STEEL (QUEBEC) LIMITED.LES ACIERS PITT (QUEBEC) LIMITEE LES PLACEMENTS J.R.S.D.INC.PLACEMENTS STE-VICTOIRE INC.LES PLACEMENTS WEJAK INC.WEJAK HOLDINGS INC.PLASTIQUES YAMASKA INC.PONT EMBROIDERY A TAPESTRIES LTD.BRODERIE & PETIT POINT PONT LTEE PORTLAND INDUSTRIAL SERVICES INC.SERVICES INDUSTRIELS PORTLAND INC.LES PROMOTIONS SAFARI INC.SAFARI PROMOTIONS INC.RECYBEC INC.REMBOURRAGE KENNEDY INC.REMISAGE D'AUTOS STE-PERPETUE INC.STE-PERPETUE CARS STORAGE INC.Saint-Constant.02 10 73 23A.7e Avenue, Lacl.ine.22 10 73 500 Place d'Armes, Suite 1200, Mont- 21 09 73 real 126.2385, rue Jolicoeur, Montréal.17 08 73 Trois-Pistoles.18 10 73 3500.avenue Verdun, Verdun.'27 00 73 1395.rue Fleury est, Montréal.26 10 73 10800 Lajeunesse.Montreal.30 10 73 Montréal.06 11 73 Montreal.19 10 73 1086, boulevard Saraguay.Pierrefonds.01 06 73 5414.boulevard Industriel, Montréal- 17 09 73 Nord.Montréal-Nord.25 09 73 4485 Industrial Boulevard, Montreal- 27 09 73 North.5, Abitibi.Place Bonaventure, Mont- 05 10 73 real.11709 Gouin Boulevard.Pierrefonds.30 08 73 3388 chemin Chambly, Longueuil.09 10 73 1255, avenue de la Place, St-Vincent- 02 11 73 de-Paul, Laval.421, rue Montréal, Sherbrooke.16 11 73 231, Notre-Dame est.Victoriaville.16 11 73 Côte-Saint-Lur.22 10 73 1400, rue Des Vétérinaires, Saint-Hya- 15 10 73 cinthe.4649 Samson Boulevard, Laval.25 09 73 707, Filiatrault.app.3, Montréal 379.29 10 73 2036.boulevard Rolland Therrien, app.08 11 73 8, Longueuil.Cité Nature, Saint-Télesphore.05 10 73 Saint- Louis-de-Pintendre.09 11 73 Sainte-Pcrpétue.26 10 73 710S_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973.Vol.105, Xo.48___ REMORQUAGE STE-FOY INC.REPARATION D'AUTOS DE COURSE LA LANCETTE INC.LALASCETTE SPEED SHOP INC.RESTAURANT CHATEAU WONG INC.CHATEAU WONG RESTAURANT INC.RESTAURANT DE PIZZAS TORO INC.TORO PIZZA RESTAURANT INC.RESTAURANT THEO INC.LES RESTAURANTS MARATHON INC.MARATHON RESTAURANTS INC.S.ROSENBERG INC.SA FAR I PAVING LTD.¦.PAVAGE SAFARI LTEE SALON FUNERAIRE RICHMOND INC.RICHMOND FUNERAL HOME INC.SALON DE HAUTE COIFFURE POUR HOMMES LE PACHA (1973) INC.SALON JEANNINE LALONDE INC.LA SELLERIE DU CHEVAL AILE LTEE.THE IVINGED HORSE SADDLE SHOP LTD.SHERBROOKE LOCOMOTIVE CRANE RENTAL INC.LOCATION DE GRUE MOBILE SHERBROOKE INC.SHERCON QUEBEC LTD.SHERCON QUEBEC LTEE SONOGRAM LTEE.SPORCO INCORPOREE.SPORCO INCORPORATED SPOTLESS PAINTING CO.MONTREAL, LTD.LA COMPAGNIE DE PEINTURE SANS TACHES.MONTREAL, LTEE STOFAB INC.MAGBD GABRIEL TARABOULSY JEWELLERY INC.BIJOUTERIE MAGED GABRIEL TARABOULSY INC.PIERRE VEROT SPORTS INC.SPORTS PIERRE VEROT INC.VINN INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS VINN LTEE 2650, boulevard Laurier, Sainte-Foy.08 11 73 Drummondville.12 10 73 Laaalle.28 09 73 173,rueSt-Urbain.Pont-Viau, Laval .25 10 73 535.rue Notre-Dame.Laurentides .17 10 73 1420 Falaise.Laval.23 10 73 Montréal.14 06 73 5587, des Marguerites.Montreal-North Ofi 11 73 Richmond.12 09 73 Montréal.07 11 73 304.rue Jarry est.Montréal.01 11 73 B.P.370.Hudson.05 11 73 Rock Forest.22 06 73 2015 Peel Street, Suite 1112, Montreal 06 11 73 110.792, rue Marsolais, Saint-Vincent-de- Il 10 73 Paul.Québec.14 11 73 7554 Terrasse St-Roch Street, Mont- 15 10 73 real.5700.rue Donahue, Saint-Laurent.24 09 73 300 Cote Vertu Street, Apt.214.Saint- 22 10 73 Laurent.378, rang 1, Val-Morin.22 10 73 90 Hampstead Road, Hampstead.28 09 73 54865-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins 54866-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Incorporation Nom I .Venu Siège social ; Head Office GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973.105- année.n° 1,8 7109 Lettres patentes (3° partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Same Siège social / Head Office Incorporation Date ARENA ROBERT FOCRNIER INC.L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE SAINTE-AGATHE INC ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA PAROISSE DE ST-LIN INC.L'ASSOCIATION DES SOUS-ENTREPRENEURS EN CONSTRUCTION DU QUEBEC ASSOCIATION HELLENIQUE DES PARENTS GRECS-ORTHODOXES DE L'ECOLE SECONDAIRE MALCOLM CAMPBELL GREEK ORTHODOX HELLENIC.ASSOCIATION OF PARENTS OF MALCOLM CAMPBELL HIGH SCHOOL ATELIERS DE REALISATIONS GRAPHIQUES DE QUEBEC LTEE BASE-BALL MINEUR DE VERDUN.VERDUN MINOR BASEBALL CENTRE DE JEUNESSE HAUTE-RIVE INC.CENTRE DE PLEIN AIR MONT JACOB DE JONQUIERE INC.LE CLUB AMITIES-LOISIRS DE L'AGE D'OR ST-LAURENT DE JONQUIERE CLUB AUTOMOBILE DE L'OUTAOUAIS INC.CLUB DE L'AGE D'OR, L'ECHO DE BROMPTONVILLE INC.CLUB DE LOISIRS LA BELLE EPOQUE.CLUB DE MOTONEIGE DU CENTRE MONSEIGNEUR BONIN LAC-MEGANTIC INC.LE CLUB DE MOTOS-NEIGE LES LOUPS DE SAINTE-HELE-NE-DE-KAMOURASKA INC.CLUB DES RETRAITES DE ST-ROCH INCORPOREE.LE CLUB LES CASAQUES DE SAULT-AU-MOUTON INC.CLUB MOTO-NEIGE GARNIER INC.CLUB MOTONEIGE ST-FRANCOIS DE MONTMAGNY INC.LE CLUB MOTOS-NEIGE DE CHICHESTER.CHAPEAU ET SHEENBORO THE CHICHESTER, CHAPEAU AND SHEENBORO SNOWMOBILE CLUB INC.LE CLUB SPORTIF ALEC INC.CORPORATION DES ARTISANS DE QUEBEC.SENTIERS DES MOTOS-NEIGE ST-JOSEPH INC.190.rue Kennedy, East-Angus.05 10 73 Sainte-Agathe-des-Monts.10 08 73 90, 16e Avenue, Saint-Lin.19 10 73 Montréal.24 09 73 Montréal.05 10 73 Québec.21 09 73 3361 Wellington, Verdun.04 09 73 Hauterive.19 10 73 Jonquière.19 09 73 Saint-Joseph-d'Alma.31 10 73 Lucerne.30 08 73 133, rue Laval, Bromptonville.24 10 73 Montréal.12 09 73 3668, rue Marquette, Lac-Mégantic.17 09 73 Sainte-Hélène.10 10 73 591, St-François-est, Québec 2 .31 08 73 Sault-au-Mouton.29 10 73 L'Ascension-de-Notre-Seigneur.15 10 73 Saint-François-de-Sales-de-la-Rivières- 06 11 73 du-Sud Chapeau.13 03 73 SaintrProsper.29 10 73 7, rue Notre-Dame, Québec 4.16 10 73 CP.543, avenue du Palais, Saint-Jo- 11 10 73 seph-de-Beauce 7110 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 1st, 1973, Vol.106, No.48 Nom.' Name Siège social / Head Office Incorporation Date \tSuite 3100, Tour de la Bourse, Mont- 07 11 73 HENRI RICHARD NIGHT INC.\treal Le directeur du service des compagnies.5I865-0 Pierre Desjardinb.\tPierre Desjardinb, 54866-o Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires\tSupplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has grunted supplementary letters patent to: Nom / Xame Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes BELORM INC.05 00 62 CANADIAN ARENA COMPANY.10 03 23 LA CIE DE GESTION ORFORD INC.21 09 61 LE CLL'B DE CHASSE LA MERE L'OIE.03 07 73 CO-MATIC INC.29 07 64 CUSTOM CRAFT UNIVERSAL INC.01 10 69 ARTISANAT SPECIAL UNIVERSEL INC.EAU MINERALE NATURELLE ST-VALLIER 02 06 72 INC.FOREST.TRUDEAU, BEYRIES & ASSOCIES 15 09 69 INC.GESTION GU1MONT BEAULIEU INC.18 09 72 GUI MONT REAUL1EU HOLDING INC.05 11 73 Ancien nom / Former name: INDUSTRIES B.M.INC.SUT.INDUSTRIES INC.23 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital 01 06 73 1) Modifiant le capital /Alteringthe capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 3) Modifiant les privilèges et restrictions,' Modifying the privileges and restrictions 4) Modifiant le nombre des adminis- trateurs / Changing the number of directors 19 09 73 Convertissant la corporation en compagnie à fonds social / Conrerrino the corporation into a company with social funds 19 10 73 I) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 2) Modifiant le capital / Altering the capital 3) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent 28 09 73 1) Ancien nom / Former name: CUSTOM CRAFT FURNITURE INC.2) Etendant les pouvoirs / Extending the powers 06 II 73 Modifiant les dispositions des lettres pa- tentes / Amendina the provisions of the letters patent 17 09 73 1) Ancien nom / Former name: FOREST BEYRIES & ASSOCIES INC.2) Modifiant le capital / Altering the capital 3) Modifiant le siège social / Changing the head office 22 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7111 Nom / Xame Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes J.MELOCHE INC.29 04 49 PAYEUR A FRERE INC.11 04 63 PARKWAY MOTOR HOMES LTD.11 12 72 LES MAISONS MOTORISEES PARKWAY LTEE LES PETROLES BRISSON INC.12 04 67 PLACEMENTS POLYDORE POULIN LTEE.26 06 73 PLATRACT INC.21 01 71 POLYBEC INC.26 03 70 JEAN-LOUIS ROULEAU INC.08 04 64 FLORENT STE-MARIE INC.30 08 66 SECURISTAT INC.05 08 69 03 10 73 Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent 16 07 73 Modifiant le capital / Altering the capital 23 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital 31 10 73 Ancien nom / Former name: GUELUMAR INC.25 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 10 10 73 Modifiant le capital / Altering the capital 28 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 15 11 73 Ancien nom / Former name: AHUNTSIC HOLDINGS INC.17 10 73 Ancien nom / Former name: MERCERIE LONGUEUIL 27 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 54865-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54865-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: \tIncorporation Dissolution Nom / Xame\t \tDate Date ASSOCIATED MAINTENANCE CORP.\t17\t04\t07\t07\t12\t73 AYLSHER HOLDINGS LTD.\t07\t04\t71\t23\t11\t73 DALMYS (QUEBEC) LIMITED.\t01\t09\t71\t07\t12\t73 HOPITAL ST-JOSEPH DE BELLEVUE.\t20\t11\t63\t30\t11\t73 LACROIX RANCH STEAK HOUSE LTD.\t15\t04\t71\t07\t12\t73 JEAN-PIERRE MASSON INC.\t30\t09\t67\t07\t12\t73 \t19\t06\t62\t07\t12\t73 NATIONAL CEMENT COMPANY (LA CIE DE CIMENT NATIONALE)\t26\t08\t26\t30\t11\t73 LES PUBLICATIONS DE SEXOLOGIE INC.\t27\t02\t07\t07\t12\t73 WARD GRAPHICS INC.\t09\t01\t69\t07\t12\t73 54865-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54865-0 Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service. 7112 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.j8 Avis d'annulation de lettres patentes (1\" avis) Notice of annulment of letters patent (1st notice) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis aux compagnies ou corporations suivantes, constituées par lettres patentes sous l'autorité de la Loi des compagnies: a) qu'elles ont omis de produire le rapport prescrit par l'article 4 de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q.1964, ch.273) pour les années indiquées; 6) et qu'en conséquence faute par elles d'avoir fourni ledit rapport pour lesdites années tel que prescrit par la loi et de payer les droits exigibles dans les 60 jours de la publication dudit avis, il entend procéder à l'annulation de la charte desdites compagnies ou corporations: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby notifies the following companies and corporations incorporated by letters patent pursuant to the Companies Act that: .(a) they have neglected to file the return required pursuant to section 4 of the Companies Information Act (KJJ.VJ.'9o4, Ch.273) for the year(s) indicated below; and that.(6) therefore, should they fail to submit the said return for the abovementioned years, as prescribed by law, and also fail to pay the required fees, within 60 days from the date of publication of this notice, he will annul their charter: Incorporation Années des rapports Droits exigibles Nom / Xamc Year(s) /or which Exigible fees Date return required\t CANADIAN CAMEO CHIME COMPANY 13 LIMITED\t09 49 1967, 1969 et/and «50.00 1971 ù/lo 1973 POISSONNERIE MATHIEU DU NORD INC.26\t05 71 1971 alto 1973.?30.C0 Le directeur du service des compagnies, 54865-0 Pierre Desjardinb.\tPierre Desjardins, 54865-0 Director of the Companies Service.Avis d'annulation de charte (2e avis)\tNotice of annulment of charter (2nd notice) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que les chartes des compagnies ou corporations ci-dessous désignées sont annulées en vertu de la Loi des compagnies:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.the charters of the following companies or corporations are annulled : Incorporation Nom de la compagnie ou corporation / Xamc of company or corporation Date\t MAURICE TURCOT CONSTRUCTION LTEE.\t \t Le directeur du service des compagnies, 54865-0 Pierre Desjardinb.\tPierre Debjardins, 54865-o Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivant:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date ADMINISTRATION SORENTIM INC.\t.COUILLARD ET ASSOCIES LTEE 11 02 72 THE CANCER RESEARCH SOCIETY INC.LA SOCIETE DE RECHERCHES SUR LE CANCER INC.THE CANCER RESEARCH SOCIETY INC.07 03 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7113 Nouveau nom / Nexc name CARIGNAN & GRAVEL, ASSURANCES.INC.ECOLE CYCLISTE DU QUEBEC.SCIERIE LORD INC.TAPIS & GARNITURES WEINBERG & FRERES INC.WEINBERG BROS.CARPET ti FURNISHINGS INC.54865-0 SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC INC.(Loi des symdicals professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 3 octobre 1973, il a autorisé le changement de nom du « SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC C.S.N.», dont la constitution, sous le nom originaire de « SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DES EMPLOYES DU BOIS OUVRE, INCORPORE*, a été autorisé le 25 août 1948, et dont le siège social est situé à Québec, en celui de \u2022 SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC INC.», et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.54929-0 SP: 2158-48 SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE CHICOUTIMI (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 13 novembre 1973, il a autorisé le changement de nom de « SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES DE CHICOUTIMI », dont la constitution, sous le nom originaire de « ASSOCIATION DES GARDES-MALADES CATHOLIQUES LICENCIEES DE LA PROVINCE DE QUEBEC, SECTION DU DIOCESE DE CHICOUTIMI », a été autorisée le 5 mai 1954.et dont le siège social est situé à Chicoutimi, en celui de « SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE CHICOUTIMI », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), Albert Jessop.54930-o SP: 3136-53 Ancien nom Incorporation Former name Date CARIGNAN ASSURANCES INC.26 06 64 ECOLE CYCLISTE 17 04 69 PROVINCIALE SCIERIE ST-CYRILLE INC.27 06 73 WEINBERG BROS.15 01 48 INCORPORATED M I ! nb, es Service.SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC INC.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on October 3, 1973, he has authorized the change of name of \"SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC C.S.N.\", whose incorporation under the original name of \"SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DES EMPLOYES DU BOIS OUVRE, INCORPORE\", was authorized on August 25.1948, and whose head office is located in Québec, to that of \"SYNDICAT DU BOIS OUVRE DE LA REGION DE QUEBEC INC.\", the foregoing pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54929 SP: 2158-48 SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE CHICOUTIMI (Professional Syndicates Ad) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on November 13, 1973, be authorized \"SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES DE CHICOUTIMI\".whose incorporation, under the original name of \"ASSOCIATION DES GARDES-MALADES CATHOLIQUES LICENCIEES DE LA PROVINCE DE QUEBEC, SECTION DU DIOCESE DE CHICOUTIMI\".was authorized on May 5, 1954, and whose head office is located in Chicoutimi, to change its name to that of \"SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS DE CHICOUTIMI\", the foregoing under the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Acting Deputy Miniister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.54930 SP: 3136-53 Le directeur du service des compagnies, Pierre Dc&i.Pierre Desjardins.54865-0 Director of the Company Syndicats professionnels Professional Syndicates 7114 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973.Vol.106, No.48 Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de mollification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.m \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.Y \u2014 In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aér'-n (personnes et choses).V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Commission des transports Québec Transport du Québec Commission GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973.105' année.11° 48 7115 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.\" In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.I \u2014 Avis de la Commission - proprio motu > La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les vingt (20) jours francs de la date de la présente publication.Rôle-Q-435 255-N-P-l TRANSPORT MARITIME VIGNEAULT LTEE Havre Saint-Pierre.'Duplessis).Que.Rôle-Q-436 14383-V-P-l PAUL LESSARD 851, Boulevard Ouest.Case postale 9 Louiseville, (Maskinongé).Que.La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Rôle-Q-437 996-DYV-P-l GAUDREAU, CLAUDEL CP.121.St-Jean Port Joli.Cté de rislet.P.Q.Rôle-Q-438 4366-V-P-l BLOUIN, CEORGES 940, avenue Royale, St-Jean, I.O., Cté de Montmorency, P.Q.RôIe-Q-439 8565-V-P-2 CENTRAL TRUCK LINES LTD.CP.1180.Val d'Or, Cté d'Abitibi-Est, P.Q.I \u2014 Notice \"proprio motu\" of the Commission The Commission gives notice of its intention to render a decision in the following matters in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of twenty (20) clear days following the date of this publication.To annul the special permit issued on October 15, 1973 and issue a new special permit, in conformity with the decision reached by the Commission on November 9, 1973.To cancel clause s of the holder's permit.The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days follow ing the date of this publication.Relativement à la confiscation du cautionnement de l'opposante Chabot Auto Inc.With regard the confiscation of the deposit made by the opposing party, Chabot Auto Inc.Pour corriger le chiffre indiqué comme montant déposé par le requérant dans sa décision du 10 octobre 1973.To correct, in its decision of October 10.1973.the figure given as being the amount deposited by the applicant.Relativement à l'annulation de la clause bb du permis de Central Truck Lines Ltd suite à la lettre des Industries D.C.B.Ltée en date du 18 octobre 1973.With regard to the cancellation of clause 56 of the permit held by Central Truck Lines Ltd.pursuant to a letter from Industries D.C.B.Ltée, dated October 18.1973.Pour révoquer le permis spécial émis le 15 octobre 1973 et émettre un nouveau permis spécial, conformément i\\ la décision prise par la Commission, le 9 novembre 1973.Pour révoquer la clause * du permis du détenteur. 7110 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Rôle-M-467 6793-V-S-l PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET 200.rue St-Jacques.9ième étage.Montréal 126, P.Q.R61e-M-468 6793-V-S-2 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET, 200.rue St-Jacques, 9ième étage.Montréal, 126, P.Q.Rôle-M-469 6793-V-S-3 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET 200.rue St-Jacques, 9ième étage, Montréal 126, P.Q.Rôle-M-470 6793-V-S-4 PAQUETTE, PAQUETTE, PERREAULT & RIVET 200, rue St-Jacques, 9ième étage Montréal 126, P.Q.II \u2014 Avis d'introduction de requête : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Brazeau Transport Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 31 août 1973.(MS-10S) Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Brazeau Transport Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 11 septembre 1973.(MS-100) Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Brazeau Trans*port Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 1er août.1973.(MS-127) Relativement au cautionnement fourni dans la cause de Brazeau Transport Inc.(6793-V) avec sa requête datée le 29 août 1973.(MS-104) With regard to the security given in the case of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated August 31, 1973.(MS-108) With regard to the security given in the case of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated September 11, 1973.(MS-100) With regard to the security given in the case of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated August 1st, J973.(MS-127) With regard to the security given in the case of Brazeau Transport Inc.(6793-V) with its application dated August 29.1973.(MS-104) Rôle Q-403 31-DYA D-l LES ENTREPRISES CIRARDIN INC., Route Transcanadienne, Drummondville, Cté Drummond.P.Q.Rôle Q-404 19296-V D-2 BEL-MONT TRANSIT INC.95, Boul.Jacques-Cartier, Mont-Joli, Cté Rimouski, P.Q.Rôle Q-405 D-6 TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., Suite 400, 1259, rue Berri, Montréal 132, Que.Nouvelle demande: La partie requérante demande a la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service I : Location à court terme (moins d'une année) d'autobus type scolaire, au sens du code de la route, a la rie Les Entreprises Girardin Inc.Route Transcanadienne Drummondville.Service 2: Location à long terme (plus d'un an) d'autobus type scolaire, au sens du code de la route, à la cie Les Entreprises Girardin Inc.Route Transcanadienne, Drummondville.Demande d'augmentation de taux de l'ordre de 10%, pour le transport de marchandises dans la région du Bas du Fleuve pour le compte de Canada Packers Ltd., contrat No CP-4.Demande de fixation de taux: 1) Supplément No 7.2) Contrat :\\ taux convenus entre Tremblay Express Ltée et The Price Company Limited.Modification de taux: augmentation: 9% sur les taux antérieurs: Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter le contrat déposé a la Commission des transports du Québec.54867-o II \u2014 Notice of submission of application : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.New application: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorise it to provide the following vehicle-leasing services: Service 1 : Leasing of school-type buses, within the meaning of the Highway Code, on a short-term basis (less than one year), to \"Les Entreprises Girardin Inc.\".Trans-Canada Highway, pruinmondville.Service 2: Leasing of school-type buses, within the meaning of the Highway Code, on a long-term basis (one year or over), to \"Les Entreprises Girardin Inc.\", Trans-Canada Highway, Drummondville.Application for a 10% increase in rates, for the transportation of goods in the Lower St.Lawrence area on behalf of Canada Packers Ltd., contract No.CP-4.Application for fixing of rates: (1) Supplement No.7.(2) Agreed-rates contract between Tremblay Express Ltée and The Price Company Limited.Modification of rates: increase: 9% over former rates: For further information, consult the contract filed with the Québec Transport Commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° iS 7117 Rùle Q-406 19296-V-D-2 BEL-MONT TRANSIT INC., 95, boul.Jacques-Cartier nord, Mont-Joli, Ct6 Rimouski, P.Q.Role Q 407 1176-A D-l TF ASBESTOS TRANSIT INC., CP.334, Il.R.No I.Plessisville.Cté Mégantic.P.Q.Rôle Q-408 73-A D-l TF AUTOBUS DES BOIS FRANCS LIMITEE, R.R.No 1, CP.384.Plessisville.Cté Mégantic.P.Q.Rôle Q-409 3323-A D-l TF AUTOCAR PORTNEUF INC., 655, Côte Joyeuse, St-Raymond, Cté Portneuf, P.Q.Modification de permis.La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distnnce -route restreinte - contrat - De Québec à Mont-Joli, pour le transport par camion isotherme, de produits alimentaires périssables (viandes de toute» catégories, produits de salaison, oeufs, volailles), pour le compte de Alp.Lafleur Ltée.de Québec et retour avec marchandises refusées.Demande de modification de taux d'environ 12% pour le service Plessisville.Vic-toriaville et Trois-Rivières.Demande d'augmentation de taux comme suit : Prix actuels: Circuit urbain: Adultes: 8 billets pour S1.00 0.15 du passage Etudiants: 10 billets pour 1.00 0.15 du passage Circuit: Plessisville-Princeville |>our Victoriaville et retour pour étudiants Cégep et secondaire seulement: $4.50 par semaine de Plessisville 4.00 par semaine de Princeville Taux proposés: Circuit urbain: Adultes: 6 billets pour 81.00 0.20 du passage Etudiants: 8 billets pour 1.00 0.20 du passage Circuit: Plessisv retour pou seulement : Rôle Q-410 10184-V D-l TF L.BRETON TRANSPORT LIMITEE, Lime Ridge.Cté Wolfe, P.Q.Circuit: Plessisville-Princeville pour Victoriaville et our pour étudiants Cégep et secondaire lulement : 35.50 livret de 10 passages Plessisville 5.00 livret de 10 passages Princeville Circuit: Victoriaville-Daveluyville-Trois-Rivières: 20% sur billet de $0.35 à S 1.00 15% sur billet de $1.05 à $2.00 10% sur billet de $2.05 et plus 1.Demande d'augmentation de tarifs pour le transport scolaire du midi, des écoles de St-Raymond à Chute Panet, Rang Ste-Croix, Allen's Mills et St-Léonard.Anciens taux : $0.30 aller-retour Taux proposés: 80.50 aller-retour 2.Demande de discontinuation du service de transport de passagers de St-Basile à Québec tous les midis.3.Demande de fixation d'une nouvelle échelle de tarifs pour les parcours suivants: \u2022 Parcours No 1 : Québec - St-Raymond -Rivière-a-Pierre.Parcours No 2: Québec - Lac St-Joseph -St-Raymond.Demande d'augmentation de taux pour le transport de marchandises expédiées par/ou destinées a Dominion Lime Limited en vertu de la clause «Ci» du permis de la requérante.Modification of permit.The applicant requests the Commission to add to its permit the following service: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Québec to Mont-Joli, for the transportation, by temperature-controlled trucks, of perishable food products (meats of all categories, salted products, eggs, poultry), on behalf of Alp.Lafleur Ltée.of Québec, and return with refused goods.Application for a modification of rates of about 12% for the service between Plessisville.Victoriaville and Trois-Rivières.Application for an increase in rates as follows: Current rates: Urban circuit: Adults: 8 tickets for $1.00 0.15 single fare Students: 10 tickets for $1.00 0.15 single fare Circuit: Plessisville-Princeville to Victoriaville and return for Cegep and secondary school students only: $4.50 per week from Plessisville 4.00 per week from Princeville Proposed rates: Urban circuit: Adults: 6 tickets for $1.00 0.20 single fare Students: 8 tickets for $1.00 0.20 single fare Circuit: Plessisville-Princeville to Victoriaville and return for Cegep and secondary school students onlv: $5.50 per booklet of 10 tickets Plessisville 5.00 per booklet of 10 tickets Princeville Circuit: Victoria ville-Daveluyville-Trois-Rivières: 20% on a ticket of $0.35 to $1.00 15% on a ticket of $1.05 to $2.00 10% on a ticket of $2.05 or more 1.Application for an increase in rates for school transportation at noon, from the schools of St.Raymond to Chute Panet, Ste.Croix Range, Allen's Mills and St.Léonard.Former rates: $0.30 round trip.Proposed rates: $0.50 round trip.Application for a cessation of the service for the transport of passengers from St.Basile to Québec at noon all the week.3.Application for fixing of a new scale of tariffs for the following routes: Route No.1 : Québec - St.Raymond -Rivière-à- Pierre.Route No.2: Québec - Lac St.Joseph -St.Raymond.Application for an increase in rates for the transportation of goods shipped by/or shipped to Dominion Lime Limited, pursuant to clause \"C\" of the applicant's permit. 7118 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, Xo.48 Rôle Q-411 12089- V-D-l JEAN-LOUIS CHAINE, 1196, ôcme Avenue, Grand'Mère, Clé St-Maurice.Hole Q-412 16903-V-D-l et 23523-V-D-l CARTIER TRANSPORT INC., 153 rue Maltais, Sept-Iles, Cté du Saguenay, et I and DEMENAGEMENT CARTIER INC., CARTIER MOVERS INC., 153 rue Maltais.Sept-Iles, Cté d\" Saguenay.Role Q-413 7466-V-D-l CAMILLE ROUSSEAU, 2097, Père Lelièvre.Québec (Duberger).et / and TRANSPORT NATIONAL ENR-, (Dame Danielle Garneau Denis), 42H boul.St-Joseph.Charlesbourg-Ouest, Cté de Québec.Rôle Q-414 3551-A-D1 LA COMPAGNIE FERLAND & BEGIN LTEE, Lac F.tchemin, Cté Dorchester, P.Q.Modification de pemis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance -territoire - contrat - fardier - De tout point à tout autre point dans la Province de Québec, pour le transport de machinerie lourde, par fardier, pour le compte de A.Plamondon & Fils Inc.de Grand'Mère.Remarque: Si cette demande est accordée, les restrictions présentement attachées au permis b'o]>-pliqueront.Cession partielle de la propriété du système de transport (vente).Cartier Transport Inc.demande l'autorisation de céder à: Déménagement Cartier Inc.-Cartier Movers Inc.153, rue Maltais.Sept-Iles.cté du Saguenay.la propriété du système de transport reliée a l'exploitation des sections B et C de son permis No 16903-V décrites comme suit : B) Transport de ménages et ameublements usagés: clauses h-1 à b-8 inclusivement : C) Transport de meubles, fournitures de magasins, bureaux, musées, hôpitaux, etc.: Clauses c-1 il c-S inclusivement; ainsi que toutes les restrictions et droits additionnels découlant des sections B et C susmentionnées.Cession de la propriété du système de transport.Camille Rousseau demande l'autorisation de céder à: Transport National Enr.(Dame Danielle Gameau Denis).42!j boul.St-Joscph, Charlesbourg-Ouest, Cté de Québec, la propriété du système de transport opéré en vertu de son permis qui se lit comme suit : No 7460-V Transport général.Quéliec et environs.Nouvelle demande de permis.Classe permis: Autobus.Service: Transport d'écoliers entre Lac Etchemin, Dorchester et Lévis-Lauzon, le vendredi soir et le dimanche soir et retour, comme suit: a) Point de départ et de destination: 1.Dimanche soir: Départ de Lac Etchemin, Hôtel Le Manoir et Restaurant Le Feu Follet, à destination de CEGEP Lévis-Lauzon et Collège de Lévis.2.Vendredi soir: Départ du CEGEP de Lévis-Lauzon et du Collège de Lévis à destination de Lac Etchemin.Ii) Parcours à suivre: Lac Etchemin route 53.route Trans-Caua-da et villes de Lévis et Lauzon, c) Horaires: 1.Dimanche soir: Départ de Lac Etchemin 7.15 p.m.arrivée à Lauzon 8.30 p.m.2.Vendredi soir: Départ de Lauzon 5.40 p.m., arrivée Lac Etchemin 7.30 p.m.d) Classe de passager: Écoliers.Modification of permit.The applicant requests to add the following service to his permit: Restricted trucking - long distance - territory - contract - float - .From any point to any other point in the Province of Québec, for the transportation of heavy equipment, by float, on behalf of A.Plamondon & Fils Inc., of Grand'Mère.Note: If this request is granted, the restrictions presently attaching to the permit shall apply.Partial transfer of the ownership of the transportation service (sale).Cartier Transport Inc.requests the authorization to transfer to: Déménagement Cartier Inc.-Cartier Movers Inc., 153 Maltais Street, Sept-Iles, County of Saguenny.the ownership of the transportation service related to the operation of sections B and C of its permit No.16903-V described as follows: (Bi Transportation of household goods and used furniture: clauses b-1 to b-8 inclusive: (C) Transportation of store, office, museum, hospital and other like furniture and equipment etc.: Clauses c-1 to c-S inclusive; as well as all restrictions and additional rights ensuing from the aforementioned sections B and C.Transfer of the ownership of the transportation service.Camille Rousseau requests authorization to transfer to: Transport National Enr., (Mrs.Danielle Gameau Denis), 42K; St.Joseph Boulevard.Charle3bourg-\\Vest, County of Québec, the ownership of the transportation service operated pursuant to its permit.which reads as follows: No.7466-V General trucking Québec and vicinity.New application for a permit.Class of permit : Bus.Service: Transportation of students between Lac Etchemin.Dorchester and Lévis-Lauzon, on Friday night and Sunday night, and return, as follows: (a) Point of departure and destination: 1.Sunday night : Departure from Lac Etchemin.Hôtel Le Manoir and Restaurant Le Feu Follet for the CEGEP de Lévis-Lauzon and Collège de Lévis.2.Friday night: Departure from the CEGEP de Lévis-Lauzon and the Collège de Levis for Lac Etchemin.(Ii) Route: Lac Etchemin Highway 53.Trans-Canada Highway and Cities of Levis and Lauzon.(c) Timetables: 1.Sunday night: Departure from Lac Etchemin 7:15 p.m.arrival at Lauzon S:30 p.m.2.Friday night: Departure from Lauzon 5:40 p.m., arrival at Lac Etchcn.in 7:30 p.m.('/) Class of passengers: Students. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 71)9 Rôle Q-415 316-A-D1 et 3281-A-D2 TRANSPORT FONTAINE LTEE, St-Gervais, Cté Bellechasse, P.Q.et / and AUTOBUS CODERE INC., 031, rue Sylvain, Thetford-Mines, Cté Mégantic, P.Q.Rôle Q-11G 3095-A-Cl DUBE & DESROSIERS TRANSPORT INC., 192, rue Morrissette, Mont-Joli, P.Q.Rôle Q-417 922-A-D1 AUTOBUS MONTMAGNY INC., 152, Ave de la Cour, Montmagny, P.Q.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder a Autobus Codère Inc., 631, rue Sylvain, Thetford-Mines, Cté Mégantic, P.Q.certain de ses services dûment autorisé en vertu de son permis 316-A-D1 comme suit, à savoir: La propriété du système de transport suivant: Classe de permis: Autobus.Service: Québec - Thetford-Mines et points intermédiaires: Sillery et Ste-Foy (via Boul.Laurier!.St-Nicolas Station, limites ouest de St-Etienne de Lauzon.St-Gilles, St-Patrice, St-Sylvestre.Leeds Village et Station, St-Pierre de Broughton.le rang 6 de Robert-sonville et Robertsonville.Parcours à suivre: De Québec à St-Nicolas Station en passant par le Pont de Québec et la route 20.De St-Nicolas Station à St-Gilles en passant dans les limites ouest du village de St-Étienne de Lauzon.De St-Gilles à Robertsonville en passant par St-Patrice, St-Sylvestre, Leeds Village et Station, St-Pierre de Broughton et le rang G de Robertsonville.De Robertsonville à Thetford-Mines, route No 1.Droit additionnel: En donnant le service autorisé, Transport Fontaine Ltée aura droit à un arrêt a St-Nicolas Station, à un endroit situé à 2,000 pieds au sud de la route No 20 et No 5, pour Québec et retour.Conditions et restrictions: a) Pas de service local entre St-Etienne et Québec.6) Pas de service local entre Robertsonville et Thetford-Mines.Service: De Leeds à Thetford-Mines, via Keenear's Mills et Pontbriand.Parcours à suivre: Route régionale reliant Leeds à Thetford-Mines, via Keenear's Mills et Pontbriand.Conditions et restrictions: Pas de service local sur la route No 1 à partir de l'intersection de ladite route et du chemin conduisant à Pontbriand jusqu'à Thetford-Mines, ces deux endroits inclus.Service : Transport de colis légers dans des véhicules affectés au transport de voyageurs.Conditions et restrictions^ Selon les conditions et restrictions imposées dans l'ordonnance No 309-A du 1er avril 1970.Convocation.Demande de vérification des services fournis par Dubé & Desrosiers Transport Inc., 192, rue Morrissette, Mont-Joli.P.Q.A la demande de Votre Choix Transport Inc., 270, rue Léonidas, Rimouski, P.Q.Modification de permis.Classe de permis: Autobus.Service: La partie requérante demande une modification de son permis 922-A qui se lit comme suit : Transfer of ownership of transportation service (sale).The applicant requests authorization to transfer to Autobus Codère Inc., G3I Sylvain Street, Thetford Minos, County of Mégantic, P.Q., some of its services duly authorized pursuant to its permit 316-A-D1 as follows, to wit: The ownership of the following transportation service: Class of permit: Bus.Service: Québec-Tlictford Mines and intermediate points: Sillery and Ste.Foy (via Laurier Boulevard).St.Nicolas Station, western limits of St.Élicnne-de-Lauzon.St.Gilles.St.Patrice.St.Sylvestre.Leeds Village and Station, St.Pierre-de-Broughton, Range G of Robertsonville and Robertsonville.Route: From Québec to St.Nicolas Station via the Québec Bridge and Highway 20.From St.Nicolas Station to St.Gilles passing within the western limits of the Village of St.Étienne-de-Lauzon.From St.Gilles to Robertsonville passing through St.Patrice.St.Sylvestre, Leeds Village and Station.St.Pierre-de-Broughton and Range 6 of Robertsonville.From Robertsonville to Thetford Mines.Highway 1.Additional right: When providing the service authorized.Transport Fontaine Ltée shall have the right to stop at St.Nicolas Station, at a point located 2.000 feet to the south of Highway 20 and 5, for Québec and return.Conditions and restrictions: (a) No local service between St.Etienne and Québec.(d) No local service between Robertsonville and Thetford Mines.Service: From Leeds to Thetford Mines, via Keenear's Mills and Pontbriand.Route: Regional Highway connecting Leeds to Thetford-Mincs.via Keenear's Mills and Pontbriand.Conditions and restrictions: No local service on Highway 1 between the point where said Highway intersects the road to Pontbriand, and Thetford Mines, including these two places.Service: Transportation of light parcels in vehicles utilized for the transportation of passengers.Conditions ana restrictions: According to the conditions and restrictions prescribed in Order No.309-A dated April 1, 1970.Summons.Request for verification of services provided by: Dubé & Desrosiers Transport Inc., 192.Morrissette.Mont-Joli.P.Q.At the request of Votre Choix Transport Inc., 270, Léonidas Street, Rimouski, P.Q.Modification of permit.Class of permit: Bus.Service: The applicant requests a modification of its permit 922-A reading as follows: 7120 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Hole Q-41S 1606-A-D2 AUTOBUS MESSIER CHIBOUGAMAU INC., 131, 5ième Avenue, Chibougamau.Cté Abitibi Est, P.Q.Rôle Q-J19 495-A-D1 GERALD FILLION, Notre-Dame du Rosaire, Cté Montmagny.Rôle Q-420 2178-A-D2 AUTOBUS LANDRY LTEE, 144, rue Notre-Dame, Ville Ste-Marie.Cté Beauce.P.Q.Sylvain & Parent, avocats.Rôle Q-421 15267-V-D-l MATANE GASPES1E TRANSPORT INC., 325.rue de la Gare, CP.335, Matane, Cté de Matane.Rôle Q-422 22811-V-D-I CHARLES A.BOUCHER.275, Malouin, Matane, Cté de Matane.Rôle Q-423 15957-V-D-2I GERARD NOLIN LIMITEE, 150, De l'Eglise, St-Jean-Chrysostome, Cté de Lévis.Des limites Est de la paroisse de St-Tho-mas-de-la-pointe-a-la-Caille à l'Hôtel-Dieu de Montmagny situé dans la partie Ouest de la même paroisse et retour et le point intermédiaire Ville de Montmagny, de manière a ce qu'on obtienne l'autorisation de rendre nos passagers au centre d'achats situé sur le boul.Taché dans les limites de la Ville de Montmagny aux heures suivantes soit: 9h.a.m.11 h.a.m., 2h.p.m.5h.p.m., du lundi au vendredi.Droit additionnel.Classe de permis: Autobus.Service: Transport régulier par autobus de résidents et d'écoliers de la Ville de Chibougamau aux Chantiers Chibougamau Ltée.situé à environ 4 milles.Nouvelle demande de permis Classe permis: Autobus.Service: Voyages spéciaux et à charte-partie, de Notre-Dame du Rosaire et de St-Léon, St-Nazaire à tout endroit dans un rayon de 250 milles.Droit additionnel.Requête pour obtenir le droit additionnel suivant : Classe permis: Autobus.Service: 1.Transport de passagers de Vallée-Jonction à tous les endroits situés dans un rayon de 150 milles de ladite municipalité et retour.2.St-EIzéar de Beauce à tous les endroits situés dans un rayon de 150 milles de ladite municipalité et retour.Modification de permis (voiturier-roulier).La partie requérante demande le permis suivant: Autorisation d'utiliser, pour le transport rte marchandises autorisé par les clauses o:\\ff inclusivement de son permis No 15267-V.le service de remorquage de: Charles A.Boucher.22811-V.voiturier-remorqueur, 275.Malouin, Matane, Cté de Matane.Demande de permis de voiturier-remorqueur.La partie requérante demande le permis suivant: Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques vides ou remplies, selon les clauses a à g inclusivement du permis No 15267-V.pour le compte de: Matane Gaspésie Transport Inc., voiturier-roulier, 325, rue de la Gare, CP.335, Matane, Cté de Matane.15267-V.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande a la Commission d'ajouter à son permis l'autorisation suivante: La détentrice est autorisée à louer, a long terme (7 ans), de Fruehauf Trailer Co.of Canada Ltd., permis 648-DYV, trois (3) remorques citernes dont la description apparaît au contrat de location déposé à la Commissi\"!!.Fruehauf Série D.YR 401001 Fruehauf Série D.YR 401004 Fruehauf Série DXR 101005 From the eastern limits of the Parish of St.Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille to 1 Hotel-Dieu of Montmagny located in the west part of said Parish and return, and the intermediate point, the City of Montmagny, so as to obtain authorization to drive our passengers to the shopping centre located on Tache Boulevard within the limits of the City of Montmagny according to the following schedule: 9:00 A.M., 11:00 A.M.2:00 P.M., 5:00 P.M.from Monday to Friday.Additional right.Class of permit: Bus.Service: Regular transportation of residents and students, by bus, from the Town of Chibougamau to the Chantiers Chibougamau Ltée, located at about 4 miles from the Town.New application for a permit.Class of permit: Bus.Service: Special or charter trips from Notre-Dame-du-Rosaire and St.Léon.St.Nazaire to any point located within a radius of 250 miles.Additional right.Application for the following additional right: Class of permit: Bus.Service: (1) Transportation of passengers from Vallée-Jonction to all points located within a radius of 150 miles from said municipality, and return.(2) St.Elzéar-de-Beauce to all points located within a radius of 150 miles from said municipality, and return.Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit: Authorization to utilize, for the transportation of goods authorized by clauses a to g inclusive of its permit No.15267-V, the haulaway service of: Charles A.Boucher, 22811-V, haulaway operator.275, Malouin, Matane, County of Matane.Application for a permit of haulaway ojier-ator.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul empty or loaded trailers with his duly-registered tractors, according to clauses a to g inclusive of permit No.15267-V, on behalf of: Matane Transport Inc., carrier, 325, de la Gare Street, P.O.Box 335.Matane, County of Matane.15267-V.Modification of permit (additional right).The applicant requests the Commission to add the following authorization to its permit: The holder is authorized to lease on a long-term basis (7 years), from Fruehauf Trailer Co.of Canada Ltd.permit 648-DYV, three (3) tank trailers, described in the lease filed with the Commission.Fruehauf Serial numberDXR 401001 Fruehauf Serial number DXR 401004 Fruehauf Serial number DXR 401005 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105- année, »' 48 7121 Rôle Q-424 19126-V-D-l MICHEL PAQUET INC., 101, Bélair, Hauterive, Cté du Saguenay.Rôle Q-425 23487-V-D-l RAYMOND BOUFFARD, L'Etang-du-Nord.Cté des Iles-de-la-Madeleine.Rôle M-681 1069-DY &806-DYV D-l MONT ROYAL FORD VENTE LTEE.2275 est, Mont-Royal.Montréal, P.Q.Rôle M-682 20309-V D-l R.LEVESQUE TRANSPORT ENRC, (R.Levac opérant sous le nom de) 1359, rue Patrice, Ville Lasalle.Que.Rôle M-683 23498-V D-l MONSIEUR MICHEL CLOUTIER, 2149, Boul.Lafontaine.Saint-Jérôme (Prévost), Que.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis les services additionnels suivants: Transport restreint - Service local -Hauterive et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de ménages.Transport restreint - service local -Baie-Comeau et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de ménages.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport général - longue distance -rayon - De L'Etang-du-Nord à tous points situés sur les Iles-de-la-Madeleine, et retour.Modification de permis.La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location de véhicules de promenade à court terme à ses clients qui ont leur voiture en réparation ou qui attendent la livraison d'un véhicule neuf.Service 2: Location à long terme (un an et plus) de véhicules de promenade (automobiles et station wagons).Service 3: Location de véhicules de commerce et de livraison (camions) a long terme (un an et plus).aemande à la Commission des transports du Québec de changer le service 1 pour qu'il se lise comme suit: Service 1 : Location à court terme de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons) à 2275 est.Mont-Royal.Montréal, et d'autoriser le service additionnel suivant: Service 4 : Location à court terme de véhicules de commerce (camions, tracteurs), à 2276 est, Mont-Royal, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente).R.Levesque Transport Enrg.(R.Levac, opérant sous le nom de) demande l'autorisation de céder h: J.C.Transport Enrg, (Marie-Denise Carmen Dulude, opérant sous le nom de).3887, rue St-Denis, Montréal, Que.la propriété du système de transport suivant: Transport général - service local -Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville.Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: St-Jérôme.Lesage.Shawbridge.Lac Guin-don, Lac Marois, Piedmont, St-Sauveur, Mont Gabriel, Mont Rolland, Ste:Adèle.Ste-Margueritc, Lac Masson, Val-Morin, Val-David, Ste-Agathe, Morin Heights.St- Modification of permit.The applicant requests that the following additional services be added to its permit: Restricted trucking - local service -Hauterive and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said town, for the transportation of household goods.Restricted trucking - local service -Baie-Comeau and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said town, for the transportation of household goods.Application for a permit.The applicant requests the following permit: General trucking - long distance - radius - From L'Etang-du-Nord to all points located on the Magdalen Islands, and return.Modification of permit: The applicant, which is authorized to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1 : Short-term leasing of pleasure vehicles to its customers whose cars are under repair or who expect the delivery of a new vehicle.Service 2: Long-term leasing (one year or over) of pleasure vehicles (automobiles and station « agons).Service 3 : Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks) on a long-term basis (one year or over).requests the Commission's authorization to amend service 1 to read as follows: Service 1: Short-term leasing of pleasure vehicles (automobiles and station wagons) at 2275 Mount Royal East.Montreal, and to authorize the following additional service : Service 4 : Short-term leasing of commercial vehicles (trucks, tractors), at 2275 Mount Royal East.Montreal.Transfer of ownership of transportation system (sale).R.Levesque Transport Enrg.(R.Levac.operating under the name of) requests authorization to transfer to: J.C.Transport Enrg.(Marie-Denise Carmen Dulude.operating under the name of).3887 St.Denis Street.Montreal, P.Q.The ownership of the following transportation system: General trucking - local service - Montreal and all points located within a distance of 5 miles from the limits of said City.New request.The applicant requests authorization from the Commission to give the following transportation service under the prescribed terms and conditions: From St.Jérôme.Lesage.Shawbridge, Lac-Guindon.Lac-Marois, Piedmont, St.Sauveur, Mont-Gabriel, Mont-Rolland, Ste.Adèle, Ste.Marguerite, Lac-Masson, Val-Morin, Val-David, Ste.Agathe, Morin- 7122 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.iS Rôle M-684 22836-V-D-l MONSIEUR JEAN-GUY PARENT, 5536, Notre-Dame de Grace.Montréal, Que.Rôle M-685 3546-A MADAME REJANE PAQUETTE, 26, rue Poitras, St-Gabriel.(Berthier) P.Q.Rôle M-686 23481-V D-l FERME V.MELOCHE ENRG., (Victor Meloche opérant sous ce nom) 4314, boul.des Sources, Dollard-des-Ormeaux, (Roxboro 970) P.Q.Rôle M-687 22795-V D-l HEYL TRUCK LINES, INC., 235, Mill Street, P.O.Box 206, Akron, Iowa 51001, U.S.A.et / and QUEBEC OFFICE: c/o Jérémie Dauphinais.Covey Hill Road, Hemmingford, P.Q.Adolphe.St-Hippolyte.Lac-Achigan.Lac Conneley, Mont-Laurier, St-Faustin.Lac Carré, Lac Supérieur, St-Jovite, Mont-Tremblant, La Conception, Labelle, L'Annonciation.Ste-Véronique.Lac-Saguay.Lac-Des-Ecorces, Mont-Laurier, Ferme Neuve et Lacoste, pour le transport de journaux, et retour avec copies non vendues.Modification.La partie requérante demande qu'à la clause a suivante: Transport restreint - service local - contrat-Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de livres d'école, pour le compte de Montréal Book Room Limited, soit ajouté l'expéditeur suivant: Book Center Inc.La requérante demande d'être autorisée à agir comme courtier en transport pour organiser des voyages originant des endroits suivants: 1) St-Charles-de-Mandeville.St-Gabriel-de-Brandon et St-Michel-des-Saints et de tout endroit situé entre St-Gabriel-de-Bran-don et St-Michel-des-Saints et retour.2) St-Gabriel-de-Brandon et Louiseville et tout endroit situé entre St-Gabriel-de-Brandon et Louiseville et retour.La partie requérante demande à la Commission, l'autorisation de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance - territoire -Service: De Dollard-des-Ormeaux et de toute municipalité a toute autre municipalité qui sont situées dans la province de Québec et retour, pour le transport de chevaux provenant de ou destinés aux propriétaires desdits chevaux.La requérante s'est adressée à la Commission afin de faire ajouter le service suivant à son permis: Classe: Transport restreint-longue distance-route restreinte - véhicules isothermes -Service: De la frontière Québec - Etats-Unis (tous ports d'entrée dans l'état de New-York) à Montréal, pour le transport, par véhicules isothermes, de viandes, produits de boucherie et produits dérivés de la viande, pour le compte de Canada Packers Limited et Steinberg's Limited, toutes deux de Montréal.(Provenance des marchandises: les entrepôts de Missouri Beef Packers, Inc.a Friona et Plainview.(Texas).Phelps City, (Missouri) et Boise (Idaho, Etats-Unis) et de tous les autres empaqueteurs de viande des états du centre-ouest et du sud des Etats-Unis.Restriction: Le service ci-dessus mentionné doit être exploité avec le certificat complémentaire No MC-133119 Sub No 6TA émis le 10 septembre 1971 par l'Intentait Commerce Commission des Etats-Unis.Heights, St.Adolphe.St.Hippolyte.Lac-Achigan, Lac-Conneley, Mont-Laurier.St.Faustin, Lac-Carré, Lac-Supérieur, St.Jovi-te.Mont-Tremblant, La Conception, Labelle, L'Annonciation, Ste.Véronique.Lac-Saguay, Lac-Des-Ecorces.Mont-Laurier, Ferme-Neuve and Lacoste, for the transportation of newspapers, and return with unsold copies.Modification.The applicant requests that, in the following clause a : Restricted trucking-local service-contract-Montreal and all points located within a distance of 5 miles from the limits of said City, for the transportation of school books, on behalf of Montreal Book Room Limited, the following shipper be added: Book Center Inc.The applicant requests authorization to act as transport broker to organize trips leaving from the following points: (1) St.Charles-de-Mandeville, St.Gabriel-de-Brandon and St.Michel-des-Saints and any point located between St.Gabriel-de-Brandon and St.Michel-des-Saints and return.(2) St.Gabriel-de-Brandon and Louiseville and any point located between St.Gabriel-de-Brandon and Louiseville and return.The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following transport service, according to the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - long distance - territory -Service: From Dollard-des-Ormeaux and any municipality to any other municipality located in the Province of Québec and return, for the transportation of horses shipped by or to the owners of said horses.The applicant has applied to the Commission in order to add the following service to its permit: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - temperature controlled units -Service: From the Québec - United States border (all ports of entry on the State of New York) to Montreal, for the tranportation, by temperature controlled vehicles, of meats, meat products and meat by-products, for the account of Canada Packers Limited and Steinberg's Limited, both of Montreal.(Origin of shipments: the storage facilities of the Missouri Beef Packers, Inc.at Friona and Plain-view, (Texas), Phelps City, (Missouri) and Boise, (Idaho, U.S.A.) and from other meat Iiackers in the Midwest and Southern United Stated.Restriction : The above mentioned service is to be operated in conjunction with a complementary certificate No.MC-133119 Sub No.6TA issued by the Interstate Commerce Commission of the United States on September 10 1971. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7123 Rôle M-688 NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU, INC., P.O.Box 184, Buffalo, N.Y.14221 Rôle M-689 M D-l TF 1417-V TRANS-ILE INC., 1500, Bellevue S.Greenfield Park, P.Q.Rôle M-690 CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N., 555, Dixon Road, Rexdale, Ontario.M9W 1H8 Rôle M-691 691-DY D-l KILDAIR SERVICE LTEE, 92, boul.St-Michel, St-Paul de Juliette et / and COURCHESNE & PERREAULT INC., 1180, boul.Manseau, Joliette, P.Q.Rôle M-692 MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE, Agent, P.O.Box 10213, Washington, D.C.20018.D.C.Rôle M-694 BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., 1259, rue Berri.Suite 460, Montréal 132, Que.H2L 4CL Rôle M-095 BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., Suite 460, 1259, rue Berri, Montréal 132, Que.Demande de fixation de tarifs.1) Supplément 2 du tarif 261-C.2) Supplément 55 du tarif 270-B.3) Supplément 56 du tarif 270-B.4) Supplément 3 du tarif 368.Réduction des taux, pour les détails veuillez consulter la Commission des transports du Québec.Demande d'augmentation de 10% a plusieurs item et fixation des taux aux item neufs.Tarif des marchandises en vrac No 640, B.TQ.No 2545.Section 4: Taux convenus par contrat, modifiés afin d'illustrer les changements et les ajouts, pour le compte de Bulk Carriers Ltd.seulement.Transfert de permis et vente de services: La compagnie requérante venderesse qui est détentrice du permis de location de véhicules suivant : Service 1: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons) à 1255, de la Naudiè-re, Joliette.Service 2: Location a long terme (une année et plus) de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons).Demande à la Commission des transports du Québec, d'autoriser la vente de ses services et le transfert de son permis en faveur de la compagnie requérante-acquéreur.Demande de fixation de tarifs.1) Supplément 7 du tarif 3-P.2) Supplément 8 du tarif 33-P.3) Supplément 9 du tarif 33-P.4) Supplément 38 du tarif 34-H.5) Supplément 39 du tarif 34-H.Réductions des taux, pour les détails, veuillez consulter la Commission des transports du Québec.Demande de fixation de taux.74ième révision au tarif 80-A.Tarif de papier.Modifications: Additions et réductions.51ième révision au tarif 15-D.Tarif de classe et de spéciaux.Modifications: Additions - augmentations - annulations - 50ième révision au tarif X-105-B.Tarif d'exception.Modifications: Additions et augmentations.Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter lesdites révisions déposées à la Commission des transports du Québec.Demande fixation de taux.15ième révision au tarif 101-C.Tarif de taux d'espèces.41ième révision au tarif 75.Tarif d'espèces courtes distances.Modifications: Additions - augmentations - annulations -Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter lesdites révisions déposées à la Commission des transports du Québec.Application for fixation of tariff: (1) Supplement 2 to tariff 261-C.(2) Supplement 55 to tariff 270-B.(3) Supplement 56 to tariff 270-B.(4) Supplement 3 to tariff 368.Reductions of rates for details consult Québec Transport Commission.Application for an increase of 10% of several items and for the fixing of tariffs or new items.Bulk Commodity Tariff No.640, T.B.Q.No.2545.Section 4: Contract rates, amended to show changes and additions on behalf of Bulk Carriers Ltd.only.Transfer of permit and sale of services.The applicant vendor is the holder of the following vehicle-leasing permit: Service 1: Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons) on a short-term basis (less than a year) at 1255, De la Naudière, Joliette.Service 2: Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons) on a long-term basis (one year or over).The applicant-vendor requests the Québec Transport Commission to authorize the sale of its services and the transfer of its permit on behalf of the applicant-purchaser.Application for fixation of tariffs: (1) Supplement 7 to tariff 3-P.(2) Supplement 8 to tariff 33-P.(3) Supplement 9 to tariff 33-P.(4) Supplement 38 to tariff 34-H.(5) Supplement 39 to tariff 34-H.Reductions of rates, for details, consult Québec Transport Commission.Application for fixation of tariffs.74th revision of tariff 80-A.Tariff for paper.Modifications: Additions and reductions.51st revision of tariff 15-D.Class tariff and special tariff.Modifications: Additions - increases - cancellations - 50th revision of tariff X-105-B.Exceptional tariff.Modifications: Additions and increases.For further information, consult said revisions filed with the Québec Transport Commission.Application for fixation of rates: 15th revision of tariff 101-C.Cash rate tariff.41st revision of tariff 75.Cash tariff for short distances.Modifications: Additions - increases - cancellations -For further information, please consult said revisions, which have been filed with the Québec Transport Commission. 7124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Rôle M-696 2771-A (D-2) DAME THERESE TRUDEAU, 5004, rue Raymond, Pierrefonds, P.Que.Rôle M-697 3541-A (R-l) DIVERSIFIED TRANSPORTATION LTD., 4810-99 Street, Edmonton, Alberta.Rôle M-698 3549-A (D.-l) LES AUTOBUS DUPLESSIS INC., 1652, rue Principale, Chomedev, Ville de Laval.P.Que.Rôle M-699 2860-A - D-l GOOD HOME NURSERY & PRE-SCHOOL LTD., 12,567 Gouin Blvd.West, Pierrefonds, P.Q.Rôle M-700 1908-A - (D-l, MADAME JEANNINE JOLIN, 7151, rue Champ Chevrier, App.3, Ville d'Anjou, MtJ\u201e P.Que.La requérante demande d'être autorisée à donner le service suivant: Classe de permis: Mini-bus (20 passagers).Service: De porte à porte, pour le transport d étudiants par mini-bus (20 passagers), fréquentant les écoles suivantes: Collège Ste-Anne, 1250, rue SWoseph, Lachine 600, P.Que.Collège Bourget, Rigaud, P.Que., Collège Beaubois, 9509 ouest, boul.Gouin, Pierrefonds.P.Que.Territoire : Ce service sera donné en cueillant l'enfant à sa porte dans les limites des municipalités de: Beaconsfield.Pointe-Claire, Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Roxboro, Ile-Bizard.Dorval, Ste-Anne, Senneville, Ile Perrot, Vaudreuil.St-Lazare, Hudson et Como, pour le transporter à l'école ou collège qu'il fréquente et le remener le soir chez lui à sa porte.La requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport à l'occasion de voyages à charte partie ou d'excursions en groupe, de passagers en provenance de Calgary et d'Edmonton (Alberta), et des endroits situés dans un rayon de 25 milles desdites municipalités et à destination des endroits au Québec ou passant à l'occasion à travers le Québec.La requérante demande à la Commission l'autorisation d'opérer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: De Ville de Laval à destination de tout point situé dans la province de Québec, et retour, pour le transport de passagers, à l'occasion de voyages à charte-partie.La requérante demande à la Commission de l'autoriser à donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'enfants âgés de trois (3) à sept (7) ans se rendant à la maternelle « Good Home Nursery & Pre-School Ltd.a située au 12,567, boul.Gouin ouest, Pierre-fonds (Que.), et retour.Ce service sera donné a partir du mois de septembre 1973 jusqu'au mois de juin 1974.Territoire: _ Ce service sera donné dans les municipalités suivantes: Ville St-Laurent - Dorval - Pointe-Claire -Pierrefonds - Dollard-des-Ormeaux - Roxboro et Montréal, dans un quadrilatère borné par les rues suivantes: Au nord: Chemin de la Côte Ste-Catherine, au sud: avenue Maplewood, à l'est: avenue Gatineau, à l'ouest: Chemin de la Côte des Neiges.La requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'Autobus.Service: Transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans, de leur domicile situé dans Ville d'Anjou et Montréal, et se rendant aux écoles suivantes: The applicant requests to be authorized to provide the following service: Class of permit: Minibus (20 passengers).Service: Door to door service by minibus (20 passengers) for the transportation of students attending the following schools: Collège Ste-Anne, 1250 St.Joseph Street, Lachine 600, P.Q.Collège Bourget, Rigaud.P.Q.Collège Beaubois, 9509 Gouin Blvd.West, Pierrefonds, P.Q.Territory : This service will be provided by picking up the children at their homes located within the limits of the following municipalities: Beaconsfield, Pointe-Claire, Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, Roxboro, Ile-Bizard, Dorval, Ste.Anne, Senneville, He Perrot, Vaudreuil, St.Lazare.Hudson and Como.carrying them to the school or college they attend and bringing them back at their homes at night.The applicant is asking for authorization to operate the following service: Class of permit: Autobus service.Service : Transportation of passengers, on chartered trips and tours groups originating in Calgary and Edmonton, Alberta and a 25 mile radius thereof, and destined to points into the Province of Québec or through the Province of Québec on an occasional basis.The applicant requests the Commission to authorize it to operate the following service: Class of permit: Bus service.Service: From the City of Laval to all points located in the Province of Québec and return, for the transportation of passengers on charter-trips.The applicant is asking the Commission to give the following service: Class of permit: Autobus service.Service: Transportation of children between three (3) to seven (7) years of age and attending the \"Good Home Nursery & Pre-School Ltd.\".located at 12,567 Gouin Blvd.West.Pierrefonds, P.Q.and return.This service will be given from September 1973 to June 1974.Territory: This service will be given in the following municipalities: Ville St-Laurent - Dorval - Pointe-Claire -Pierrefonds - Dollard-des-Ormeaux - Roxboro and Montreal bordered by the following streets: North: Chemin de la Côte Ste-Catherine.South: Maplewood Ave.East: Gatineau Ave.West: Chemin de la Côte des Neiges.The applicant requests to be authorized to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service: Transportation, from their homes located in Town of Anjou and Montreal, of children aged three (3) to seven (7) years attending the following schools: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7125 Rôle iM-701 2313-A - (D-l) MADAME CECILE LECARE, 1739, rue Boisvert.Vimont, (Laval).P.Que.Rôle M-702 2645-A (D-3) PAQUETTE AUTOBUS INC., 295.Grande Côte, St-Eustache.Cté Deux-Montagnes, P.Que.Rôle M-703 5427-V-D-l RIMOUSKI TRANSPORT LTEE, 377 est, 2e Rue.Rimouski, Que.Rôle M-704 23465-V-D-l MONSIEUR LIONEL MONETTE, 8367, Place Croissy, Ville d'Anjou, Que.Jardin Madeleine St-Jacques, 6283 Avenue Merriam, Ville d'Anjou, Mtl, P.Que.Ecole Michelin.8506, Place Verdelle, Ville d'Anjou, Mtl, P.Que, Maternelle d'Anjou, 8405, rue Wilfrid Pelletier, Ville d'Anjou, Mtl.P.Que.Pensionnat Notre-Dame-des-Anges.5690.boulevard Rosemont, Rosemont, Montréal, P.Que.Studio Ker Annick Enr.7973 Place Mon-trichard.Ville d'Anjou, Mtl, P.Que.Ecole de Ballet Classique, 8246, Avenue Chatillon, Ville d'Anjou, Mtl, P.Que.Ce service sera donné pour la période scolaire de chaque année.La partie requérante demande l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'Autobus.Service : Transport d'enfants de trois (3) & sept (7) ans, de leur domicile situé dans Ville Laval et fréquentant l'école maternelle suivante, et retour: Royaume des Bambins, 1739, rue Boisvert.Vimont, (Laval), P.Que.Ce service sera donné pour la période scolaire de chaque année.La requérante qui opère divers services en vertu de son permis demande à la Commission l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'étudiants de la cité de St-Eustache à destination de l'Ecole Progressive, rue Crémazie.à Montréal et retour le matin et le soir du lundi au vendredi de chaque semaine.Parcours à suivre: Route 8, Boul.Dagenais, Route 15, boul.Métropolitain.Conditions et restrictions: 1) Le service est restreint au transport des étudiants à destination de l'Ecole Progressive et retour.2) Ce service ne sera donné que le matin et le soir du lundi au vendredi de chaque semaine.3) Le coût du transport sera défrayé par les parents des étudiants.4) La détentrice ne pourra se prévaloir des privilèges conférés par l'Ordonnance générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou A charte-partie.Courtier en transport pour utiliser un service de transport par remorquage (haulaway).Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 5427-V, selon les clauses a à o en utilisant le service de remorquage de Lionel Monette.Transport par remorquage (haulaway) seulement - contrat - Le détenteur appelé voiturier-remorqueur demande l'autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier Rimouski Transport Ltée, dans les cadres du permis No 5427-V, selon les clauses a à o, de ce dernier et pour son compte.Jardin Madeleine St-Jacques, 6283 Merriam Avenue, Town of Anjou, Mtl., P.Q.Ecole Michelin, 8506 Place Verdelle, Town of Anjou, Mtl., P.Q.Maternelle d'Anjou.8405 Wilfrid Pelletier Street, Town of Anjou, Mtl., P.Q.Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, 5690 Rosemont Boulevard.Rosemont, Mtl., P.Q.Studio Ker Annick Enr.7973 Place Mont-richard, Town of Anjou, Mtl., P.Q.Ecole de Ballet Classique.8246 Chatillon Avenue, Town of Anjou, Mtl., P.Q.This service shall be given each year during the school session.The applicant requests to be authorized to give the following service: Class of permit: Bus service.Service: Transportation, from their homes located in the City of Laval of children aged three (3) to seven (7) years, attending the following kindergarten, and return: Royaume des Bambins, 1739 Boisvert Street, Vimont (Laval).P.Q.This service shall be given each year during the school session.The applicant who operates various services according to its permit, requests the Commission to authorize it to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service: Transportation of students from the Town of St.Eustache to Ecole Progressive, Crémazie Street, in Montreal and return, morning and night, from Monday through Friday of each week.Route: Highway 8, Dagenais Boulevard, Highway 15.Metropolitan Boulevard, Conditions and restrictions: (1) This service shall be restricted to the transportation of students attending Ecole Progressive and return.(2) This service shall be given each week from Monday through Friday, morning and night.(3) The cost of transportation shall be borne by the parents of the students.(4) The permit-holder cannot avail itself of any of the privileges granted by General Order No.17 respecting special or charter-party trips.Transport broker to utilize a haulaway transportation service.Transport broker service for the transportation of goods authorized by clauses o to o of its carrier's permit No.5427-V.utilizing the haulaway service provided by Lionel Monette, designated as haulaway operator.Haulaway transportation only - contract - The permit-holder, designated as haulaway operator, requests authorization to haul, with his duly-registered tractors, the trailers (empty or loaded) belonging to carrier Rimouski Transport Ltée according to clauses a to o of the latter's permit No.6427-V and on behalf of said carrier.54867-0 7126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 V \u2014 Avis de décisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it.in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS Date Requérants A pplieanls Bulletin G.O.Q.page I date Cause Cote I).'ri-ii des employés publics (Statuts refondus du Québec.1964, chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Loi du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Michel Carrier, membre de la Sûreté du Québec à Fort-George: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi des employés publics (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Loi du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Serge Barbeau, membre de la Sûreté du Québec à Fort-George: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi des employés publics (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Loi du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Roméo Lecompte, membre de la Sûreté du Québec à Fort-Chimo: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi des employés publics (Statuts refondus du Québec.1964, chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Ix>i du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Jacques Ferland, membre de la Sûreté du Québec à Fort-Chimo: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'arricle 11 de la Ix>i des employés publics (Statuts refondus du Québec, 1964.chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la I-oi du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Martin Nicole, membre de la Sûreté du Québec à Fort-George: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'article 11 de la l.oi des employés publics (Statuts refondus du Québec.1964.chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Ix>i du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Monsieur Guy Sénécal, membre de la Sûreté du Québec à Fort-Chimo: autorisé à recevoir le serment ou l'affirmation d'allégeance et d'office, conformément aux dispositions de l'article 11 de la \\jo\\ des employés publics (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 12) remplacé par l'article 14 de la Loi du ministère de la fonction publique (chapitre 14 des lois de 1969).Québec, le 21 novembre 1973.Le sous-procureur gfnfral adjoint, 54s6s-0 JbAX Alahik.Appointments Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointments by commission under the Great Seal of the Province: Québec, October 3, 1973.Mr.Gilles Paré, member of the Québec Police Force at Poste-dc-la-Baleine: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Michel Carrier, member of the Québec Police Force at Fort-George : authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec.1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Serge Barbeau, member of the Québec Police Force at Fort-George: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Roméo Lecompte, member of the Québec Police Force at Fort-Chimo: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the pro\\isions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Jacques Ferland, member of the Québec Police Force at Fort-Chimo: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec.1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Martin Nicole, member of the Québec Police Force at Fort-George: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with, the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec.1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Mr.Sénécal, member of the Québec Police Force at Fort-Chimo: authorized to administer the oath of allegiance and office, in compliance with the provisions of section 11 of the Public Officers Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 12) replaced by section 14 of the Civil Service Department Act (Chapter 14 of the Statutes of 1969).Québec, November 21.1973.Jean Alarie, 54868 Assistant Deputy Attorney General. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 1,8 7163 Avis est donné qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par commission sous le grand sceau de la province, les nominations suivantes: Québec, le 19 septembre 1973.Me Bernard Pinard, avocat, nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec; ledit Me Bernard Pinard, comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe 6) de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 19 septembre 1973.M.Roger Savard, juge de la Cour des sessions de la paix à Montréal jusqu'au 1er novembre 1973.nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964.chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal; ledit M.Roger Savard.comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe 6) de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 1er novembre 1973.Québec, le 25 septembre 1973.Me Maurice Tessier, avocat, nommé en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec; ledit Me Maurice Tessier, comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer sous l'autorité du paragraphe b) de l'article 482 du Code Criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 25 septembre 1973.Me Bernard Desjarlais.c.r., avocat et membre du Barreau du Québec, 1600.avenue Stephens.Verdun.Montréal 204, nomme en vertu de l'article 117 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20 et ses amendements), juge de la Cour provinciale pour exercer la juridiction prévue par l'article 126 de cette loi dans toute la province mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal; ledit Me Bernard Desjarlais, comme juge de la Cour provinciale, étant autorisé à exercer, sous l'autorité du paragraphe b) de l'article 482 du Code criminel, la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter du 15 octobre 1973.Québec, le 21 novembre 1973.Le sous-procureur général adjoint, 54868-0 Jeax Àlahie.Notice is given that the Lieutenant-Governor in Council has been pleased to make the following appointments by commission under the Great Seal of the Province: Québec, September 19, 1973.Me Bernard Pinard, lawyer, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments), Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act throughout the Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Québec; said Me Bernard Pinard, in view of his appointment as Judge of the Provincial Court, being empowered to exercise, under paragraph (6) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from September 19, 1973.Mr.Roger Savard, Judge of the Court of the Sessions of the Peace in Montreal until Xovemher 1, 1973, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments).Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act throughout the Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Montreal; said Mr.Roger Savard.in view of his appointment as Judge of the Provincial Court, being empowered to exercise, under paragraph (b) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from November 1, 1973.Québec, September 25, 1973.Me.Maurice Tessier.lawyer, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments).Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act throughout the Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Québec; said Me.Maurice Tessier, in view of his appointment as Judge of the Provincial Court, being empowered to exercise, under paragraph (6) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from September 25, 1973.Me Bernard Desjarlais, q.c, lawyer, member of the Bar of Québec, 1600 Stephens Avenue, Verdun, Montreal 204, appointed under section 117 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20 and amendments), Judge of the Provincial Court to exercise the jurisdiction provided by section 126 of said Act throughout the Province but particularly and without restriction in the Judicial District of Montreal; said Me.Bernard Desjarlais, in view of his appointment as Judge of the Provincial Court, being empowered to exercise, under paragraph (6) of section 482 of the Criminal Code, the jurisdiction of Magistrate under Part XVI of said Criminal Code, the foregoing to take effect from October 15, 1973.Québec, November 21, 1973.Jean Alarie, 54868-0 Assistant Deputy Attorney General. 7164 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st.1973, Vol.195, No.iS Régie de l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the plan as professionals or who have ceased to practice in this capacity, as well as the date on which their withdrawal or non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted bv order in council No.27, dated January 6, 1971.Dale effective du désengagement Effective dale of withdrawal Liste par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de l'assurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil No 27, en date du 6 janvier 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest, Bureau 1017, Montréal 128, (Québec) 29-01-71 Région de Québec \u2014 Québec Region Mino.Roland.Case postale 7395, Québec 7, (Québec) 30-05-71 Tremblay, Jacques, 590, Saint-Cyrille ouest, Québec 6, (Québec) 23-05-71 Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Chamard, John McLean, 1509, Sherbrooke West, Suite 18A, Montréal 109, (Québec) 16-08-72 Région de Témiscamingue\u2014 Têmiscamiiigue Region Bellehumeur, Claude, 10 rue McQuaig est, Rouyn, (Québec) 08-06-72 Professionnels non-participants Non-participating professionals Dale effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical Specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612, St.John's Road, Suite 114, Pointe-Claire 720, (Québec) 01-12-70 Aronovitch, Michael, 4119, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Barker, Charles S., 9, Nelson, Montréal 263, (Québec) 01-12-70 Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights, (Québec) 01-12-70 Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal 389, (Québec) 24-09-72 Boulanger, Jean-Baptiste, 3610, avenue Atwater, Montréal 109, (Québec) 16-04-71 Brabander, Joachim, 1390, Sherbrooke Street West, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Brow, Georges-Raymond, 1374, Sherbrooke Street West, Suite 7, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Browman, Mark, 7841 - 2nd Avenue, Montréal 455, (Québec) 30-07-71 Butler, Albert-A., Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Cantero, Antonio, 1396, Sainte-Catherine ouest, Montréal 107, (Québec) 01-12-70 Caplan, Ronald-M., 1390, Sherbrooke Street West, #2.Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Copping, Gordon A., 724, Upper Belmont Avenue, Montréal 217, (Québec) 01-12-70 Cordeau, Claire, 1392, Jean-Talon est, #301, Montréal 329, (Québec) 06-01-73 David, Paul-P., 8705, rue Barbeau, Montréal 457, (Québec) 01-12-70 Dawson, Howard L., 14, Bellevue Avenue, Westmount 217, (Québec) 01-12-70 Dumais.Gaston, 12245, Grenet, Suite 112, Montréal 390, (Québec) 27-03-71 Eakin, W.W., 1538, Sherbrooke Street West, Apartment 704, Montréal 109, (Québec) 15-01-71 Fullerton, C.W., 1414, Drummond Street, Montréal 107, (Québec) 01-12-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7165 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical specialists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Gélinas, André, 565, Javelin, Dorval 740, (Québec) 01-12-70 Genest, Armand, 30, boulevard St-Joseph est.Suite 818, Montréal 151, (Québec) 29-01-71 Gold, Michael M.A., 5785, Côte des Neiges, Apartment 105, Montréal 249, (Québec) 01-12-70 Hunt, Brian R., 1538, Sherbrooke West, Apt.622, Montréal 109, (Québec) 03-01-73 Johnston, Kenneth B-, Main Road, Hudson, Vaudreuil (Québec) 31-12-70 Korenberg, Lela C, 1538, Sherbrooke Street West, #601, Montréal 109, (Quelle) 26-08-72 Korenberg, Morton, Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Kravitz, Henry, 4994, Circle Road, Montréal 248, (Québec) 10-06-72 Larivière, Paul, 3484, avenue Laval, Montréal 130, (Québec) 01-12-70 Legendrc, J.-Henri, 969, boul.Saint-Joseph est, Appartement 3, Montréal 176, (Québec) 01-12-70 Levy, Léonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal 109, (Québec) 06-04-73 Macdonald, Allison D., 3550, Côte des Neiges, Suite 110, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 MacFarlane, Malcolm R., 1538, Sherbrooke Street West, #601, Montréal 109, 26-08-72 (Québec) Maguirc, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, Westmount, Montréal 215, (Québec) 13-02-71 Manseau, J.Arthur, 960, boulevard Saint-Joseph est, Montréal 176, (Québec) 01-12-70 Mason, Edward Halton, 3465, Côte des Neiges Road, Suite 81, Montréal 109, (Québec) 07-01-71 Melhado, Gerald Carlton, 900, Sherbrooke Street West, Montréal 110, (Québec) 01-01-71 Moll, Albert Edward, 3550, Côte des Neiges Road, Suite 570, Montréal 109, (Québec) 25-04-72 Montgomery, Lome C, 556, Grosvenor Avenue, Montréal 217, (Québec) 01-12-70 Morin, Paul.680, Saint-Denis, Saint-Hvacinthe, (Québec) 01-12-70 Nadler, Norman-J., 4141, Sherbrooke Ouest,#540, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Naiman, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montréal 215, (Québec) 01-03-72 Nerman, Yale, 1115, Sherbrooke West, Suite 1403, Montréal 110, (Québec) 03-01-71 Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, Appartement 1, Montréal 251, (Québec) 01-12-70 Raginsky, Bernard B., 376, Redfern Avenue, Suite 2, Montréal 215, (Québec) 01-12-70 Redmond, Lila, Medical Arts Bldg., #520, Montreal 109, (Québec) 01-12-70 Robert, Paul, 3489, avenue Atwater, Appartement 6, Montréal 109, (Québec) 03-02-71 Scott, W.Clifford M., 1260, McGregor Avenue, Suite 405, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Smith, Clifton Conway, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1020, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Smith, Frederick Mclver, 3550, Côte des Neiges, Suite 640, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Stein, Samuel, 1025 Pine Avenue West, Montréal 112, (Québec) 01-07-72 Tucker, Elrie Clifford, 1390, Sherbrooke Street West, Apt.2, Montréal 109, (Québec) 01-12-70 Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointe, Donat, 220.Grande-Allée est, app.650, Québec 4, (Québec) 13-01-71 Larue, Lucien, 964, Casot, Québec 6, (Québec) 26-12-70 Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillery, Québec 6, (Québec) 01-12-70 Médecins omnipraticiens General Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Archambault, Paul-A., 2805, Willowdale, Montréal 250, (Québec) 01-05-71 Brouille, Raynald, 3775, Saint-Hubert, Appartement 10, Montréal 132, (Québec) 02-01-71 Chevrefils.Paul-E., 7960, Saint-Denis, Montréal 327, (Québec) 13-12-70 Jacques, Elphège, 190, rue Principale est, Farnham, (Québec) 01-12-70 Gordon, Lionel, 6235A, Lennox Avenue, Montréal 251, (Québec) 15-01-72 Joannette.Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal 265, (Québec) 01-12-70 Leclaire, Yves, 4780, Côte des Neiges, Suite 32, Montréal 247, (Québec) 01-12-70 Mayman, Abe, 5845, Côte des Neiges, Suite 690, Montréal 249, (Québec) 17-12-70 Morgentaler, Henry, 2990, Beaugrand, Montréal 429, (Québec) 05-01-71 Ostiguv, Jean-Paul, 450, rue Sherbrooke est, Suite 108, Montréal 132, (Québec) 01-12-70 Scott, Benjamin H., 5146, Westburv Avenue, Montreal 248, (Québec) 22-07-71 Vines, Norman M., 1452, Bishop Street, Suite 3, Montréal 107, (Québec) 01-12-70 7166 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins omnipraticiens General Practitioners .Région de Trois-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Rinfret, Charles-G., 3179, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, Québec 10, (Québec) Samson, J.W., 725, 68e Rue est, Québec 7, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., Case postale 1500, John Manvillc Clinic, Asbestos, Richmond, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Beaulieu, J.-Édouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville, (Québec) Bieniecki, Irena, 531, Rockland Avenue, Montréal 153, (Québec) Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal 154, (Québec) Bourke, Edward T., 18, Thornhill Avenue, Westmount 217, (Québec) Boyles, Williams Howard, 1414, Drummond Street, Suite 422, Montréal 107, (Québec) Burns, Frank Leonard, 1414, Drummond Street, Suite 1022, Montréal 107, (Québec) Bushel!, Winston C, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1006, Montréal 109, (Québec) Caplan, Herbert, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 912 - 913, Montréal 109, (Québec) Casey, Charles-A., 4695, Sherbrooke Street West, Montreal 215, (Québec) Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, Suite 218, Montréal 248, (Québec) Coulombe, Roger, 4660, boulevard St-Joseph, Lachine, (Québec) DeGrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal 404, (Québec) Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Dundass, Roberta Phelps 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Elo, James-Thomas, 1414, Drummond Street, Suite 909, Montréal 107, (Québec) Felgar, Arthur, 5025.Sherbrooke West.#260, Westmount, Montréal, (Québec) Franklin, Gérald, 4078, Gage Road.Montreal 218, (Québec) Gendron, Roland, 900 Sherbrooke ouest, Suite 12, Montréal 110, (Québec) Harvey, Robert-F., 1650, Cedar Avenue, Montréal 109, (Québec) Henry, Donald Ward, 227, Kenaston Avenue, Montreal 305, (Québec) Kent, Léonard E., 4695, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) Kutzman, Ernest-Abraham, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 410, Montréal 109, (Québec) Labelle, Paul, 11,271, Henri d'Arles, Montréal 389, (Québec) Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal 205, (Québec) Lalanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville, (Québec) Lawlor, Robert, 333, Chemin Reine-Marie, Montréal 247, (Québec) Lefebvre, Pierrc-L, 2225, boulevard Lapinière, Ville Brossard, (Québec) Legault, L-Vict'ir, 5757.Decelles, #336, Montréal 251, (Québec) Litvack, Sylvia M.5465, Queen Mary Road, Apartment 610, Montréal 248, (Québec) Munro.David John, 3550, Cote des Neiges, #900, Montréal.(Québec) Muroff, Frederick, 1414, Drummond Street, Suite 1104, Montréal 107, (Québec) Myles, Thomas A., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 412, Montréal 109, (Québec) Orny, Sophie, 4980, Dornal Avenue, Montréal 248, (Québec) Parent, Benoit, Place Victoria, app.808, Montréal 115, (Québec) Pearson, Hyman H., 4780, Côte des Neiges Rd., Apartment 19, Montréal 247, (Québec) Poch,, Lewis-Neville, 1, Westmount Square, Suite 346, Westmount 216, (Québec) Rogers, Mervyn Allen, 4300, boulevard de Maisonneuve ouest, Appartement 702, Montréal 215, (Québec) Rudick, Gérald-S., 4950, Queen Marv Road, Suite 400, Montréal 248, (Québec) Stockwell, William Gordon, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montreal 109, (Québec) 21-10-71 13-12-70 27-07-72 01-12-70 30-03-71 02-09-72 15-04-71 09-03-71 02-03-71 13-02-71 10-02-71 11-01-73 27-03-71 03-02-71 25-02-71 08-04-72 03-03-73 29-10-73 16-02-71 01-12-73 19-11-72 07-03-73 15-04-71 31-01-71 07-04-71 01-02-71 11-08-71 13-02-71 17-01-73 18-02-71 02-02-71 01-12-73 01-05-71 07-12-73 10-03-71 01-02-71 29-11-73 23-08-72 06-02-71 14-04-71 06-02-71 30-01-71 09-03-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1er décembre 1973.105' année.n° 48 7167 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation ChirurgieDS-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Sykora, Oskar Paul, Dental Clinic, 1660, Cedar, Montreal 109, (Québec) Van Vliet, Jonothan E., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montreal 109, (Québec) Vinet, Ephrem, 426, boulevard St-Joseph est, Montréal 176, (Québec) Weinlander.Gérard H.G.1650, Cedar, Montreal 109, (Québec) Weinstein, Paul R., 5025, Sherbrooke West, #260, Montréal 260, (Québec) Wise, Martin, 3860, Notre-Dame Blvd., Chomedy, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Boucher, Marc, 1000, Chemin Ste-Foy, Suite 302, Québec 6, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Toicnships Region Dugal, Paul-Laurent, 459A, Lindsay, Drummondville, (Québec) Gosselin, Viateur, 854, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) Laforce, Jacques, 31, King ouest, Suite 310, Sherbrooke, (Québec) Leblanc, Jean-Yves, Case postale 851, Bedford, (Québec) Marcoux, Jean-F., 448 rue King ouest, app.4, Sherbrooke, (Québec) Olivier, Valmore H., 843, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) Région de l'Oulaouais \u2014 Outaouais Region Proulx, Jacques, 214, boulevard Saint-Joseph, Hull, (Québec) Optométristes Optometrists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Breton, Antonio, 1530, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, (Québec) Pharmaciens Pharmacists Région de Québec \u2014 Québec Region Auger, Raoul, 1606, Rouville, Ste-Foy, Québec 10, (Québec) Laliberté, Jean, Fortierville, Lotbinière, (Québec) Thibault, Urbain, 9926, Royale, Ste-Anne-de-Beaupré, (Québec) Région de Montréal \u2014 Montreal Region Jacques, Elphège, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Jacques, Paul-Léon, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Moisan, Maurice, 3477, Drummond, App.503, Montréal 107, (Québec) Podlog, Charles, 531.Abercorn, Ville Mont-Royal, Montréal 305, (Québec) Venne.Rosario, St-Hippoiyte, Cté Terrebonne, (Québec) Région du Bas Saint-Laurent \u2014 Lower St.Lawrence Region Martin, Roch, rue Saint-Edmond, Lac-au-Saumon, Matapédia, (Québec) Région du Saguenay, Lac St-Jean \u2014 Saguenay, Lake St-John Region Tremblay, Jean-Marie, Case postale 40, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saguenay, (Québec) Région du Nord-Ouest \u2014 North West Region Morin, Léo-Paul, Case postale 570, rue Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie, Témiscamingue, (Québec) Surkis, Max, 68, avenue des Pins, Lebel-sur-Quévillon, Abitibi, (Québec) 54954-o 31-01-71 08-03-71 08-02-71 08-10-73 01-12-73 29-11-73 31-01-71 08-02-71 16-05-73 04-02-71 06-02-71 11-04-71 07-02-71 05-05-71 31-12-70 29-06-73 26-10-72 22-09-72 15-09-72 15-09-72 05-01-73 15-03-73 04-04-73 16-09-72 05-10-72 01-10-72 16-11-72 7168 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, Np.48 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies Institutions, Companies et coopératives and Cooperatives Assurances Insurance FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY Arisd'aniiulatioiide permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK.NEW JERSEY ».dont le siège social est situé à Newark.New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans le Québec, a réassuré toutes ses affaires dans le Québec avec «THE DOMINION INSURANCE CORPORATION » dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 30 juin 1973.et lequel contrat de réassurance a pris effet le 1er juillet 1973; Attendu que «THE DOMINION INSURANCE CORPORATION » est dûment autorisée à faire affaires dans le Québec; Attendu que « FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY », s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK.NEW JERSEY », sont annulés à compter du 30 juin 1973.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er novembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, le surintendant des assurances.54923-48-2-0 RoGEB-A.Camaraire.THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK », dont le siège social est situé à New York, Etats-Unis d'Amérique, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans le Québec, a réassuré toutes ses affaires dans le Québec avec « THE DOMINION INSURANCE CORPORATION » dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 30 juin 1973, et lequel contrat de réassurance a pris effet le 1er juillet 1973; Attendu que « THE DOMINION INSURANCE CORPORATION » est dûment autorisée à faire affaires dans le Québec; FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY Sotice of Cancellation of Licetice and Certificate of Registration Whereas \"FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK.NEW JERSEY\", whose head office is situated at Newark.New Jersey.United States of America, which company was duly authorized to do business in Québec, has reinsured all its business in Québec with \"THE DOMINION INSURANCE CORPORATION\" whose head office is situated at Toronto, Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 30th of June 1973, with effect from the 1st of July 1973; Whereas \"THE DOMINION INSURANCE CORPORATION\" is duly authorized to do business in Québec; Whereas \"FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK.NEW JERSEY\" has complied with the provisions of section 103 of the Insurance Act; Consequently, notice is herebv given that the licence and certificate of registration of \"FIREMEN'S INSURANCE COMPANY OF NEWARK, NEW JERSEY\" are cancelled as from the 30th of June 1973.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of November 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 54923-48-2-0 Superintendent of Insurance.THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK Xotice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas \"THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK\" whose head office is situated at New \\ ork.United States of America, which company was duly authorized to do business in Québec has reinsured all its business in Québec with \"THE DOMINION INSURANCE CORPORATION\" whose head office is situated at Toronto.Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 30th of June 1973, with'effect from 1st of Julv 1973: Whereas \"THE DOMINION INSURANCE CORPORATION\" is duly authorized to do business in Québec; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7169 Attendu que « THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de «THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK » sont annulés à compter du 30 juin 1973.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er novembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, le surintendant des assurances, 54924-48-2-0 Roger-A.Camarairë.Proclamations Canada, Province de HUGUES I.APOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salit.Proclamation Attendu qu'en vertu de l'article 82 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans chacun des districts judiciaires autres que ceux de Québec et de Montréal, par proclamation, ordonner la tenue de la Cour des sessions de la paix pour ces districts aux époques et aux endroits, dans chacun de ces districts, qu'il juge à propos; Attendu que, par l'arrêté en conseil numéro 613 du 13 mai 1948, la Cour des sessions de la paix est autorisée à siéger au chef-lieu dans le district judiciaire de Labellc; Attendu Qu'en vertu de l'article 416 de ladite loi, modifiée par l'article 10 de la loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires (projet de loi 2, sanctionné le 6 juillet 1973), le tribunal dans le district judiciaire de I.abelle a juridiction concurrente avec celui de Hull et celui de Pontiac sur un certain nombre de cantons situés à une grande distance du chef-lieu; Attendu Qu'il serait opportun, en raison de l'étendue du territoire desservi, que la Cour des sessions de la paix tienne aussi ses séances dans la ville de Maniwaki de façon à éviter des frais additionnels inutiles aux parties, aux témoins et au gouvernement; A ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le Whereas \"THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK\" has complied with the provisions of section 103 of the Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of \"THE FIDELITY AND CASUALTY COMPANY OF NEW YORK\" are cancelled as from the 30th of June 1973.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of November 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 54924-48-2-0 Superintendent of Insurance.Proclamations Canada.Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth., Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas pursuant to section 82 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20), the Lieutenant-Governor in Council may, in each of the judicial districts other than Québec and Montreal, order by proclamation the Court of the Sessions of the Peace to be held in such districts, at such times and at such places in each district as he may think proper; Whereas, pursuant to Order in Council number 613, dated May 13, 1948, the Court of the Sessions of the Peace is authorized to hold its sittings at the chief-place in the Judicial District of Labelle; Whereas, under section 416 of said Act, amended by section 10 of the Act to amend the Courts of Justice Act (Bill 2, assented to on July 6,1973), the court in the Judicial District of Labelle shall have concurrent jurisdiction with that of Hull and of Pontiac over a certain number of townships located a long distance away from the chief-place; Whereas it would be expedient, owing to the considerable extend of the territory under its jurisdiction, that the Court of the Sessions of the Peace also holds its sittings in the Town of Maniwaki in order to avoid unnecessary additional costs to the parties involved, to the witnesses and to the Government; Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 7170 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, Ko.48 numéro 3780-73, du 22 octobre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la justice: Que, conformément aux dispositions de l'article 82 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 20), la Cour des sessions de la paix, autorisée à siéger à Mont-Laurier en vertu de l'arrêté en conseil numéro 613 du 13 mai 1948, tienne aussi ses séances dans la ville de Maniwaki, autant de fois que les fins de l'administration de la justice le requièrent.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Es foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-deuxième jour d'octobre en Canné mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Jean Alarie.Libro: 501 Folio: 166 54868-o 3780-73, dated October 22, 1973, We have decreed and ordered and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Justice: That, in conformity with the provisions of section 82 of the Courts of Justice Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 20), the Court of the Sessions of the Peace, being authorized to hold sittings in Mont-Laurier pursuant to Order in Council number 613, dated May 13, 1948, shall also hold sittings in the Town of Maniwaki, as often as may be required for the proper administration of justice.Of allof which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to he hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-second day of October in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command.Jean Alarie, Assistant Deputy Attorney General.Libro: 501 Folio: 166 54868 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.J ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Bourlamaquc, comprenant les lots 162, 163 et 164 du rang B, située dans la division d'enregistrement d'Abi-tibi, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territoties.Queen.Head of the Commonwealth, defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Bourlamaque, comprising lots 162, 163, and 164 of Range B located in the Abitibi Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 106' aimée, n° 48 7171 le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement d'Abitibi, à Amos; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement d'Abitibi, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Bourlamaquc.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3967-73.du 31 octobre 1973.Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec.1964.chapitre 320).ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent -.qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement d'Abi-titi, à Amos, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Kourlamaque, comprenant les lots 162, 163 et 164 du rang B, située dans la division d'enregistrement d'Abitibi; b) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Bourlamaquc; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p.ch.lieutenant-gouverneur ,' 43 7189 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $31,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission 'devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville d'Amos s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 357 tel que modifié \u2014 $150,000 \u2014 aqueduc: 377 \u2014 $46,500 \u2014 aqueduc; 378 \u2014 $35,000 \u2014 acquisition d'une aérogare; 379 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduc et égouts; 380' \u2014 $39,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, lundi, le 17 décembre 1973, Hôtel de ville, 62, 3e Avenue est, ville d'Amos, comté d'Abitibi-Ouest, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Amos (Comté d'Abitibi-Ouest), ce 22 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier, Emery Bobdeleau.Hôtel de ville, 62, 3e Avenue est, Ville d'Amos (Abitibi-Ouest), P.Q.Téléphone: 732-5218, code 819.54908-o Cité de Chambly Comté de Chambly Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Madame Marthe E.Montgrain, greffier.Hôtel de Ville, 601, rue Hôtel de Ville, Chambly, comté de Chambly.P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi le 17 décembre 1973 pour l'achat de $1,811,000 d'obligations de la cité de Chambly, comté de Chambly datées du 15 janvier 1974 et remboursables en séiie du 15 janvier 1975 au 15 janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8% ni supérieur à 9% payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they arc issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $31,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Amos agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 357 as amended \u2014 $150,000\u2014waterworks: 377 \u2014 $46,500 \u2014 waterworks; 378 \u2014 $35,000 \u2014 purchase of an air terminal; 379 \u2014 $100,000 \u2014 waterworks and sewers; 380 \u2014 $39,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case mav be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Monday, December 17, 1973, at the Town Hall, 62 -3rd Avenue East, Town of Amos, Countv of Abitibi-West, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Amos (County of Abitibi-West), November 22, 1973.Emery Bordeleau, Secretary-Treasurer.Town Hall, 62 - 3rd Avenue East, Town of Amos (Abitibi-West), P.Q.Telephone : 732-5218, code 819.54908 City of Chambly County of Chambly Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Marthe E.Montgrain, City Clerk, at the City Hall, 601 Hôtel de Ville Street, Chambly.County of Chambly.P.Q., until 8:30 o'clock p.m., on Monday, December 17, 1973 for the purchase of a bond issue of $1,811,000 for the City of Chambly, County of Chambly, dated January 15, 1974, and redeemable serially from January 15, 1975 to January 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should 7190 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.106, No.48 l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,811,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 01 1975.$214,000 15 01 1976 .234,000 15 01 1977 .254,000 15 01 1978.75,000 15 01 1979.80.000 15 01 1980.87.000 15 01 1981.93,000 15 01 1982.100.000 15 01 1983.108.000 15 01 1984.75.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le soled reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $71,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 janvier 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront compoiter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $71,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 15, 1974.Redemption table \u2014 81,811,000 \u2014 20 years \tDate\t\t( 'apital 15\t01\t1985.\t.$ 32,000 15\t1)1\t1986.\t.35,000 15\t111\t1987.\t.38,000 15\t01\t1988.\t.42,000 15\t01\t1989.\t.46,000 15\t01\t1990.\t.50,000 15\t01\t1991.\t.54,000 15\t01\t1992.\t.59,000 15\t01\t1993.\t.64,000 15\t01\t1994.\t.71,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $71,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term l>onds for an amount greater than $71,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7191 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Chambly s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 96 \u2014 $61,400 \u2014 renouvellement d'emprunt; 104 \u2014 $5,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 109 \u2014 $5,900 \u2014 renouvellement d'emprunt; 112 \u2014 $27,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 115 \u2014 $47,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 118 \u2014 $4,400 \u2014 renouvellement d'emprunt; 120 \u2014 $1,600 \u2014 renouvellement d'emprunt; 125 \u2014 $23,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 126 \u2014 $28,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 127 \u2014 $6,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 128 \u2014 $6,600 \u2014 renouvellement d'emprunt; 133 \u2014 $13,400 \u2014 renouvellement d'emprunt; 134 \u2014 $17,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 137 \u2014 $1,800 \u2014 renouvellement d'emprunt; 143 \u2014 $20,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 144 \u2014 $9,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 145 \u2014 $9,400 \u2014 renouvellement d'emprunt; 134 \u2014 $1,523,000 \u2014aqueduc, égouts, voirie, éclairage.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue lundi le 17 décembre 1973, à 8.30 heures du soir, Hôtel de Ville, 601, rue Hôtel de Ville, Chambly, comté de Chambly, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chambly (Comté de Chambly) ce 26 novembre 1973.Le greffier, Mme Marthe E.Montgrain.Hôtel de Ville, 601, rue Hôtel de Ville, Chambly, Comté de Chambly, P.Q.Téléphone: 658-8788, code 514.54948-o Ville de Touraine Comté de Gatineau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean Gervais, greffier.Hôtel de ville, 12 avenue Picardie, Touraine, comté de Gatineau, P.Q., jusqu'à 8:00 heures du soir, lundi le 17 décembre 1973, pour l'achat de $661,000 d'obligations de la ville de Touraine, comté de Gatineau, datées du 15 janvier 1974 et remboursables en série du 15 janvier 1975 au 15 janvier 1994 inclusivement, avec l'intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellementles 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Chambly agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 15, 1974 without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bond will be issued pursuant to the following bylaws: 96 \u2014 $61,400 \u2014 loan renewal; 104 \u2014 $5,000 \u2014 loan renewal; 109 \u2014 $5,900 \u2014 loan renewal; 112 \u2014 $27,000 \u2014 loan renewal; 115 \u2014 $47,500 \u2014 loan renewal; 118 \u2014 $4,400 \u2014 loan renewal; 120 \u2014 $1,600 \u2014 loan renewal; 125 \u2014 $23,000 \u2014 loan renewal; 126 \u2014 $28,000 \u2014 loan renewal; 127 \u2014 $6,500 \u2014 loan renewal; 128 \u2014 $6,600 \u2014 loan renewal; 133 \u2014 $13,400 \u2014 loan renewal; 134 \u2014 $17,000 \u2014 loan renewal; 137 \u2014 $1,800 \u2014 loan renewal; 143 \u2014 $20,500 \u2014 loan renewal; 144 \u2014 $9,000 \u2014 loan renewal; 145 \u2014 $9,400 \u2014 loan renewal; 134 \u2014 $1,523,000 \u2014 waterworks, sewers, roads, lighting.Tenders will opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, December 17, 1973, at 8:30 o'clock p.m., at the City Hall, 601 Hôtel de Ville Street, Chambly, County of Chambly, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of'the tenders.Chambly, (County of Chambly) November 26, 1973.Mrs.Marthe E.Montgrain, City Clerk.City Hall, 601 Hôtel de Ville Street, Chambly, County of Chambly, P.Q.Telephone: 658-8788, code 514.54948 Town of Touraine County of Gatineau Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jean Gervais, Town Clerk, at the Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine, County of Gatineau, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, December 17,1973, for the purchase of a bond issue of $661,000 for the Town of Touraine, County of Gatineau, dated January 15, 1974, and redeemable serially from January 15, 1975 to January 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. 7192 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $661,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 01 1975.$ 31,000 15 01 1976.32,000 15 01 1977 .36,000 15 01 1978.16,000 15 01 1979.18,000 15 01 1980.11,000 15 01 1981.13,000 15 01 1982.14,000 15 01 1983.15,000 15 01 1984.15,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $48,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet exédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 janvier 1999 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 janvier 1994 au montant de $240,000 comprend un solde de $204.000 renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans, et échéant comme suit: For adjudication purposes only, interest will be culated as from January 15, 1974.Redemption table \u2014 $661,000 \u2014 SO years Date Capital 15 01 1985.$ 17,000 15 01 1986.19.000 15 01 1987.21,000 15 01 1988 .22,000 15 01 1989 .23,000 15 01 1990.25,000 15 01 1991.29,000 15 01 1992.31,000 15 01 1993.33,000 15 01 1994.240,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $48,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of January 15, 1999 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of January 15, 1994 in the amount of $240,000 includes a balance of $204,000 renewable for an additional 5-year period, maturing as follows: Date Capital 15 01 1995.$34,000 15 01 1996.37,000 15 01 1997.41,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Date Capital 15 01 1998.$44,000 15 01 1999.48,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capita! and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of said bank in Toronto, Ontario. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7193 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $240,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéance apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Touraine s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 451 \u2014$28.500 \u2014 achat de machinerie; 455 \u2014 $150,000 \u2014 aqueduc, égout; 456 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduc, égout, voirie; 466 \u2014 $42,000 \u2014 voirie; 472 \u2014 $80,000 \u2014 aqueduc, égout, voirie; 481 \u2014 $30,500 \u2014 achat de machinerie; 488 \u2014 $30,000 \u2014 achat de machinerie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue lundi le 17 décembre 1973, à 8:00 heures du soir, Hôtel de ville, 12 avenue Picardie, Touraine, comté de Gatineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus Iiaute ni aucune des soumissions.Touraine (Comté de Gatineau), ce 19 novembre 1973.Le greffier, Jean Gervais.Hôtel de ville, 12 avenue Picardie, Touraine, Comté de Gatineau, P.Q.Téléphone: 776-5591, code 819.54870-o Village de Pont-Rouge Comté de Portneuf Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Yves Laroche, secrétaire-trésorier, Centre paroissial.Case postale 339, Village de Pont-Rouge, comté de Portneuf, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 19 décembre 1973, pour l'achat de $339,000 d'obligations du village de Pont-Rouge, comté de Portneuf, datées du 15 janvier 1974 et remboursables en série du 15 janvier 1975 au 15 janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $240,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Touraine agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 451 \u2014 $28,500 \u2014 purchase of equipment; 455 \u2014 $150,000 \u2014 waterworks, sewers; 456 \u2014 $300,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 466 \u2014 $42,000 \u2014 roads; 472 \u2014 $80,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 481 \u2014 $30,500 \u2014 purchase of machinery; 488 \u2014 $30,000 \u2014 purchase of machinery.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, December 17, 1973, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine, County of Gatineau, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Touraine (County of Gatineau), November 19, 1973.Jean Gervais.Toivn Clerk.Town Hall, 12 Picardie Avenue, Touraine, County of Gatineau, P.Q.Telephone: 776-5591, code 819.54870 Village of Pont-Rouge County of Portneuf Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Yves Laroche.Secretary-Treasurer, Parish Center, Post Office Box 339, Village of Pont-Rouge, County of Portneuf, P.Q.until 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, December 19, 1973.for the purchase of a bond issue of $339,000 for the Village of Pont-Rouge, County of Portneuf, dated January 15, 1974, and redeemable serially from January 15, 1975 to January 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.43 7194 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 janvier 1974.Tableau d'amortissement \u2014 8339,000 \u2014 20 ans Année Capital 15 01 1975.8 5,000 15 01 1976.6,000 15 01 1977.6,500 15 01 1978.7,000 15 01 1979.4,000 15 01 1980.4,000 15 01 1981.4,000 15 01 1982.5,000 15 01 1983.5,000 15 01 1984.5,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $27,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 janvier 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 janvier 1994 au montant de $209,000 comprend un solde de $196,500 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 01 1995.$13,500 15 01 1996.15,000 15 01 1997.15,500 15 01 1998.17,000 15 01 1999.18,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 15, 1974.Redemption table \u2014 $339,000 \u2014 SO years Date Capital 15 01 1985.$ 6,000 15 01 1986.7,000 15 01 1987.7,000 15 01 1988.8,000 15 01 1989.8,000 15 01 1990.9,500 15 01 1991.10,000 15 01 1992.10,500 15 01 1993.12,000 15 01 1994.209,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $27,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of January 15 2004 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of January 15, 1994 in the amount of $209,000 includes a balance of $196,500 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 01 2000.$20,000 15 01 2001.21,500 15 01 2002.23,500 15 01 2003.25,000 15 01 2004.27,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n' 48 7195 Lesdites obligations ne seront pas racbetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $209,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.Le village de Pont-Rouge s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 110 \u2014 $13,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 161 \u2014 $326,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 19 décembre 1973, à 8.00 heures du soir.Centre paroissial.Case postale 339, Village de Pont-Rouge, comté de Portneuf, Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni.aucune des soumissions.Village de Pont-Rouge (Comté de Portneuf), ce 26 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier, Yves Laroche.Centre paroissial.Case postale 339, Village de Pont-Rouge, Comté de Portneuf, Québec.Téléphone: 873-4481, code 418.54936-o The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $209,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Village of Pont-Rouge agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after January 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 110 \u2014 $13,000 \u2014 loan renewal; 161 \u2014 $326,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, December 19, 1973, at 8:00 o'clock p.m., at the Parish Centre, Post Office Box 339, Village of Pont-Rouge, County of Portneuf, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Village of Pont-Rouge (County of Portneuf), November 26, 1973.Yves Laroche, Secretary-Treasurer.Parish Centre, Post Office Box 339, Village of Pont-Rouge, County of Portneuf, Québec.Telephone: 873-4481, code 418.54936 Ville de Granby Comté de Shefford Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Donat Brosseau, greffier.Hôtel de ville 87, rue Principale, Granby, comté de Shefford, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 18 décembre 1973, pour l'achat de $1,995,000 d'obligations de la ville de Granby, comté de Shefford, datées du 15 janvier 1974 et remboursables en série du 15 janvier 1975 au 15 janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8% ni supérieur à 9% payable semi-annuellemenl les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utitisé, le montant émis a chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 janvier 1974.City of Granby County of Shefford Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Donat Brosseau, clerk, at the City Hall, 87 Principale Street, Granby, County of Shefford, (P.Q.), until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, December 18, 1973, for the purchase of a bond issue of $1,995,000 for the City of Granby, County of Shefford, dated January 15, 1974 and redeemable serially from January 15,1975 to January 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complere annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 15, 1974. 7196 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Tableau d'amortissement \u2014 $1,995,000.\u2014 20 ans Date Capital 15 01 1975.$ 51,000 15 01 1976 .53,000 15 01 1977 .58,000 15 01 1978 .64,000 15 01 1979.68,000 15 01 1980.73,000 15 01 1981 .81,000 15 01 1982 .88,000 15 01 1983 .94,000 15 01 1984.104,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté a la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $176.000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 janvier 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $176.000.et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Granby s'engage à ne pas émettre ele nouvelles obligations sur le marché canadien dans Redemption table \u2014 $1,995,000 \u2014 êO years Date Capital 15 01 1985.$ 87,000 15 01 1986.93,000 15 01 1987 .99,000 15 01 1988.109,000 15 01 1989.117,000 15 01 1990.128,000 15 01 1991.138,000 15 01 1992.149,000 15 01 1993.165,000 15 01 1994.176,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $176,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, anel should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be maele according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the main office of said bank in Toronto, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $176.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Granby agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7197 'es soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 689 \u2014 $150,000 \u2014 aqueduc et égouts; 748-71 \u2014 $45,000 \u2014 voirie; 769-72 \u2014 $400.000 \u2014voirie; 790-72 \u2014 $5,000 \u2014 aqueduc; 795-72 \u2014 $40.000 \u2014 voirie; 806-72 \u2014 $375,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 833-73 \u2014 $70,000 \u2014 aqueduc et égouts; 834-73 \u2014 $30,000 \u2014 aqueduc; 835-73 \u2014 $160,000 \u2014 aqueduc et égouts; 836-73 \u2014 $130,000 aqueduc et égouts; 837-73 \u2014 $28,000 \u2014 aqueduc et égouts; 838-73 \u2014 $16,000 \u2014 aqueduc et égouts 839-73 \u2014 $38,000 \u2014 aqueduc et égouts; 840-73 \u2014 $19,000 \u2014 aqueduc et egouts; 844-73 \u2014 $17,000 \u2014 aqueduc et égouts; 851-73 \u2014 $234,000 \u2014 travaux du parc de stationnement; 853-73 \u2014 $160,000 \u2014 achat de terrains; 854-73 \u2014 $78,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas.qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mardi, le 18 décembre 1973, Hôtel de ville, 87, rue Principale, Granby, comté de Shefford, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Granby (Comté de Shefford), ce 26 novembre 1973.Le greffier, Dokat Biïosseau.Hôtel de ville 87, rue Principale, Granby, (Comté de Shefford), P.Q.Téléphone: 372-6671 code 514.54947-o upon, from and after January 15, 1974 without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 689 \u2014 $150,000 \u2014 waterworks and sewers; 748-71 \u2014 $45.000 \u2014 roads; 769-72 \u2014 $400,000 \u2014 roads; 790-72 \u2014 $5,000 \u2014 waterworks; 795-72 \u2014 $40.000 \u2014 roads; 806-72 \u2014 $375.000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 833-73 \u2014 $70.000 \u2014 waterworks and sewers; 834-73 \u2014 $30.000 \u2014 waterworks; 835-73 \u2014 $160,000 \u2014 waterworks and sewers; 836-73 \u2014 $130,000 \u2014 waterworks and sewers; 837-73 \u2014 $28,000 \u2014 waterworks and sewers; 838-73 \u2014 $16,000 \u2014 waterworks and sewers; 839-73 \u2014 $38,000 \u2014 waterworks and sewers; 840-73 \u2014 $19.000 \u2014 waterworks and sewers; 844-73 \u2014 $17,000 \u2014waterworks and sewers; 851-73 \u2014 $234.000 work on the parking lot; 853-73 \u2014 $160,000 \u2014 purchase of land; 854-73 \u2014 $78,000 \u2014 waterworks, sewers and roads.The tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday.December 18, 1973, at the City Hall, 87 Principale Street, Granby, County of Shefford, (P.Q.).The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Granby (County of Shefford), November 26, 1973.donat BrOSSEAU, Clerk.City Hall, 87 Principale Street, Granby (Shefford), P.Q.Telephone: 372-6671, Code 514.54947 Ville de Chibougamau Comté d'Abitibi-Est Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gérard Savard, secrétaitre-trésorier, Hôtel de ville, 650, 3e Rue, Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, le 20 décembre 1973 pour l'achat de $1,688.000 d'obligations de la ville de Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, datées du 15 janvier 1974 et remboursables en série du 15 janvier 1975 au 15 janvier 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable scmi-annuel-lement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 janvier 1974.Town of Chibougamau County of Abitibi-East Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Gérard Savard, Secretary-Treasurer, at the Town-Hall, 650-3rd Street, Chibougamau, County of Abitibi-East, P.Q., until 8:00 p.m., on Thursday, December 20, 1973, for the purchase of a bond issue of $1,688,000 for the Town of Chibougamau, County of Abitibi-East, dated January 15, 1974 and redeemable serially from January 15, 1975 to January 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8% nor more than 9%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each différent rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from January 15,1974. 7198 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Tableau d'amortissement \u2014 $1,688,000 \u2014 20 ans \tDate\tCapital 15\t01 1975.\t.$ 55,000 15\t01 1976.\t.60,000 15\t01 1977.\t.64,000 15\t01 1978.\t.69,000 15\t01 1979.\t.74,000 15\t01 1980.\t.79,000 15\t01 1981.\t.86,000 15\t01 1982.\t.93,000 15\t01 1983.\t.101,000 15\t01 1984.\t.59,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $134,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 janvier 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payabls à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto et à Ottawa, Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $134,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 janvier de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Chibougamau s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les Redemption table \u2014 81,688,000 \u2014 20 years Date Capital 15 01 1985.S 64,000 15 01 1986 .70,000 15 01 1987.74,000 15 01 1988.82,000 15 01 1989.88,000 15 01 1990.96,000 15 01 1991.104,000 15 01 1992.113,000 15 01 1993.123,000 15 01 1994.134,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $134,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of January 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of the said bank in Toronto and Ottawa, Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $134,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on January 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Chibougamau agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7199 soixante jours à compter du 15 janvier 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 85 \u2014 $79,750 \u2014 renouvellement d'emprunt: 92 \u2014 $163,750 \u2014 renouvellement d'emprunt; 158 \u2014 $808,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 170 \u2014 $636,500 \u2014 aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, jeudi, le 20 décembre 1973, Hôtel de ville, 650, 3e Rue, Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chibougamau (Comté d'Abitibi-Est), ce 21 novembre 1973.Le secrétaire-trésorier.Gérard Savard.Hôtel de ville, 650, 3e Rue, Chibougamau, (Abitibi-Est), P.Q.Téléphone 276-2688 (extension 24), code 819.54909-o days upon, from and after January 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 85 \u2014 $79,750 \u2014 loan renewal; 92 \u2014 $163,750 \u2014 loan renewal; 158 \u2014 $808,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 170 \u2014 8636,500 \u2014 waterworks, sewers and roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Thursday, December 20, 1973, at the Town-Hall, 650 3rd Street, Chibougamau, County of Abitibi-East, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Chibougamau, (County of Abitibi-East), November 21,1973.Gérard Savard, Secretary-Treasurer.Town-Hall, 650 - 3rd Street, Chibougamau (Abitibi-East), P.Q., Telephone: 276-2688 (extension 24), code 819.54909 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Lettres patentes Attendu que, sous l'autorité de la Loi des cités et villes (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 193 et amendements), le conseil municipal de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite, comté de L'Assomption, régi par le Code municipal de la province de Québec, Nous a présenté, conformément à une résolution adoptée le 6 novembre 1972, une requête demandant que le territoire de ladite municipalité de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite, tel que décrit dans la description officielle du ministère des terres et forêts datée du 20 juin 1973, soit constitué en une municipalité de ville comprenant trois quartiers représentés par un maire et six conseillers; Attendu Qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la Loi des cités et villes, le lieutenant-gouverneur Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greetino.Letters Patent Whereas, under the Cities and Towns Act, (Revised Statutes, 1964, Chapter 193), the Municipal Council of the Parish of St.Paul-l'Ermite, County of L'Assomption, governed by the Municipal Code of the Province of Québec, has presented to Us, pursuant to a resolution adopted on November 6, 1972, a petition praying that the territory of said Municipality of the Parish of St.Paul-l'Ermite, as described in the official description of the Department of Lands and Forest, dated June 20, 1973, be constituted as a town municipality comprising three wards, represented by a mayor and six councillors; Whereas, pursuant to the provisions of section 12 of the Cities and Towns Act, the Lieutenant-Governor 7200 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December let, 1973, Vol.105, No.43 en conseil peut, par lettres patentes, constituer en municipalité de ville toute municipalité du Québec régie par le Code municipal, si sa population est d'au moins deux mille habitants, après l'accomplissement des formalités prescrites dans ladite loi; Attendu que la population de la municipalité de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite est de 3,967 habitants; Attendu que les formalités prescrites par la loi ont été observées; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête du conseil municipal de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 3992-73, du 31 octobre 1973, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi des cités et villes.Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la propositions du ministre des affaires municipales: Que le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite tel que décrit dans une description officielle du ministère des terres et forêts datée du 20 juin 1973, soit constitué en une municipalité de ville sous le nom de « Ville de Saint-Paul-l'Ermite * conformément à la demande contenue dans une requête du conseil municipal de la paroisse de Saint-Paul-l'Ermite, comté de L'Assomption, datée du 26 mars 1973; Que la ville de Saint-Paul-l'Ermite comprenne trois quartiers et que le conseil municipal de cette ville soit composé d'un maire et de six conseillers; Que la première session générale du conseil de cette municipalité ait lieu à l'hôtel de ville, au numéro 1, montée des Arsenaux, Saint-Paul-l'Ermite.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce trente et unième jour d'octobre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Libro: 1536 Le sous-procureur général adjoint.Folio: 126 Jean Alarie.« Avis de l'octroi des lettres patentes ci-dessus est donné conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193) ».Le sous-ministre des affaires municipales, 54903-o Richard Beaulieu.in council may, by letters patent, constitute as a town municipality any municipality governed by the Municipal Code if it has a population of at least two thousand inhabitants, after the formalities prescribed in said act have been complied with; Whereas, the Municipality of the Parish of St.Paul-l'Ermite has a population of 3,967 inhabitants; Whereas the formalities prescribed by law have been observed; Whereas it is expedient to accede to this petition of the Municipal Council of the Parish of St.Paul-l'Ermite.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree bearing number 3992-73, dated October 31, 1973, and pursuant to the provisions of subsection 3 of section 15 of the Cities and Towns Act, We have decreed and ordered and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Municipal Affairs: That the territory of the Municipality of the Parish of St.Paul-l'Ermite, as described in an official description of the Department of Lands and Forest, dated June 20, 1973, be constituted as a town municipality under the name of \"Town of St.Paul-l'Ermite\", pursuant to the request contained in a petition of the Municipal Council of the Parish of St.Paul-l'Ermite, County of L'Assomption, dated March 26, 1973; That the Town of St.Paul-l'Ermite comprise three wards and that the Municipal Council of this Town be composed of one mayor and six councillors; That the first general meeting of the Council of said Municipality be held at the Town Hall, at number 1, Montée-des-Arsenaux, St.Paul-l'Ermite.In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, |Lieuten-ant-Govemor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in our Province of Québec, this thirty-first day of October in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Libro: 1536 Jean Alarie, Folio: 126 Assistant Deputy Attorney General.Notice of the granting of the herein above letters patent is given pursuant to the provisions of section 15 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 1964, chapter 193).Richard Beaulieu, 54903-o Deputy Minister of Municipal Affairs. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n° 48 7201 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis set seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.HAUTERIVE Canada \u2014 Province de Québec Cour supérieure \u2014 District de Hauterive ( T A SOCIETE CENTRALE D'HYPO-No 7901.S J-' THEQUES & LOGEMENT, demanderesse, FRANÇOIS FRANCOEUR, défendeur, LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de la division de Saguenay, mis en cause.La subdivision neuf de la subdivision quatre du lot originaire numéro quatre-un.Rang un, (lot 4-1-4-9 rang 1) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton Laflèche, Ville de Hauterive, comté de Sa» guenay avec la maison dessus construite, circonstances et dépendances, portant le numéro civique 1600 boul.Manicouagan, Hauterive.Pour être vendu au bureau du registrateur de la première division d'enregistrement de Saguenay, au Palais de Justice de Baie Comeau, MARDI, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1974 à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif adjoint, Charlotte Bergeron, Baie Comeau, 21 novembre 1973.54906-o JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Terrebonne / A LEX BREMNER LTD., une corpo-No 25,168.') ration légalement constituée, ayant ' une place d'affaires à St-Antoine, district de Terrebonne, demanderesse, vs MASBEC CONSTRUCTION INC., une corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires à 493 Chemin Pin-court, à Mascouche, district de Joliette, défenderesse.« Le lot numéro quarante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent trente-deux (432-42) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Mascouche avec une maison dessus en voie de construction portant le numéro 997 rue Legardeur, à Mascouche.» Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de l'Assomption, à l'Assomption, district de Joliette, JEUDI, le DIX-SEPTIÈME jour de JANVIER 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Christian Roy.Joliette, le 21 novembre 1973.54933-0 Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective limes and places mentioned below.HAUTERIVE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Hauterive ( fi ENTRAL MORTGAGE AND HOU-No.7901.S SING CORPORATION, plaintif, vs FRANÇOIS FRANCOEUR, defendant, and THE REGISTRAR for the Saguenay Division Registry Office, mis en cause.Subdivision nine of subdivision four of original lot number four-one, Range One.(lot 4-1-4-9 Range 1) on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the Township of Laflèche, Town of Hauterive, County of Saguenay, with the house erected thereon, appurtenances and dependencies, bearing civic number 1600 Manicouagan Boulevard, Hauterive.To be sold at the Office of the Registrar of the Saguenay First Registration Division, at the court House of Baie Comeau, on TUESDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Charlotte Bergeron, Assistant Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Baie Comeau, November 21, 1973.5490g JOLIETTE Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Terrebonne _ / A LEX BREMNER LTD., a corpora-No.25,168.) tion legally incorporated, having a I place of business in St.Antoine, District of Terrebonne, plaintiff.M MASBEC CONSTRUCTION INC., a corporation legally incorporated, having a place of business at 493 Pincourt Road, in Mascouche, District of .Joliette, defendant.Lot number forty-two of the official subdivision of original lot number four hundred thirty-two (432-42) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Mascouche.with a house under construction thereon bearing number 997 Legardeur Street, in Mascouche.\" To be sold at the Office of the l'Assomption Registration Division, in l'Assomption, District of Joliette, on THURSDAY, the SEVENTEENTH day of JANUARY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Christian Roy, Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, November 21, 1973.54933 7202 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 Fieri Facias de Bonis et de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Terrebonne / A LEX BREMNER LTD., une corpo-No 25,169.) ration légalement constituée, ayant ' une place d'affaires à Ville St-Antoine, district de Terrebonne, demanderesse, l's MASBEC CONSTRUCTION INC., une corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires à 493 Chemin Pincourt, à Mascouche, district de Joliette.« Le lot numéro quarante-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre cent trente-deux (432-43) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Mascouche avec une maison dessus en voie de construction portant le numéro 1001 Legardeur, à Mascouche.» Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de l'Assomption, à l'Assomption, district de Joliette, JEUDI, le DIX-SEPTIÈME jour de JANVIER 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif, Bureau du Shérif, Christian Roy.Joliette.le 21 novembre 1973.54934-0 Fieri Facias de Bonis et de Terns Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Terrebonne i A LEX BREMNER LTD.a corpora-No.25.169.-) tion legally incorporated, having a ' place of business in the Town of St.Antoine, District of Terrebonne, plaintiff, vs MASBEC CONSTRUCTION INC., a corporation legally incorporated, having a place of business at 493 Pincourt Road in Mascouche, District of Joliette.\"Lot number forty-three of the official subdivision of original lot number four hundred thirty-two (432-43) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Mascouche, with a house under construction thereon, bearing number 1001 Legardcur, in Mascouche.\" To be sold at the Office of the L'Assomption Registration Division in L'Assomption.District of Joliette.on THURSDAY, the TWENTY-SEVENTH day of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Christian Rot, Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, November 21, 1973.54934 KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Kamouraska l TNAME ALICE RACICOT GELINAS, No 26,807.< industrielle, domjciliée à St-Peters- ' burg Beach, Floride, États-Unis d'Amérique, et à Cabano, dans le district de Kamouraska, épouse séparée de biens de Richard Gélinas, des mêmes endroits, demanderesse, vs ARSENE LEVESQUE, de Ste-Rita, comté de Rivière-du-Loup, dans le district de Kamouraska, défendeur.« Le lot numéro 19, canton Raudot, cinquième (5e) rang du cadastre officiel de la paroisse Sainte-Rita dans le district de Kamouraska.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement division de Témiscouata, situé à 65A, rue Iberville, Rivière-du-Loup, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Maurice Morin.Rivière-du-Loup, ce 21 novembre 1973.54935-0 KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Kamouraska ( TNAME ALICE RACICOT GELINAS, No.26,807.-) industrialist, domiciled in St.' Petersburg Beach, Florida, United States of America, and in Cabano, in the District of Kamouraska, wife, separate as to property, of Richard Gélinas, of same localities, plaintiff, vs ARSENE LEVESQUE, of St.Rita.County of Rivière-du-Loup, in the District of Kamouraska, defendant.\"Lot number 19 in the Township of Raudot, in the Fifth (5th) Range, on the official cadastre for the Parish of Ste.Rita, in the District of Kamouraska.\" To be sold at the Témiscouata Registration Division Office, located at 65A Iberville Street, Rivière-du-Loup, on the FIFTEENTH day of JANUARY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Maurice Morix, Sheriff's Office, Sheriff.Rivière-du-Loup, November 21, 1973.54935 LABELLE LABELLE Canada \u2014 Province de Québec District de Labelle Cour Provinciale, ( \"\"TRANS-CANADA CREDIT No 5538.< 1 CORP., demanderesse, nsMA-l RIUS ROY, défendeur.« Une partie du lot de terre portant le numéro un A rang deux, du Canton d'Egan, laquelle partie de terrain Canada \u2014 Province of Québec District of Labelle Provincial Court, ( TYRANS-CANADA CREDIT No.5538.\\ 1 CORP., plaintiff, vs MARIUS I ROY, defendant.\"A part of a lot of land bearing number one A, in Range Two, in the Township of Égan, which piece of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n' 48 7203 peut être plus particulièrement décrite comme suit, savoir: borné à l'est par le chemin public et de tous autres cotés par le résidu dudit lot 1 A, rang 2 commençant au point A indiqué sur le plan annexé et signé pour identification par lesdits parties avec et en présence du notaire soussigné, étant le coin sud-est du lot 1 A au point ou la ligne de division entre les rangs A et 2 rencontrent le chemin public.Du point A suivant le chemin public dans une direction nord-est une distance de 988 pieds au point B étant le coin nord-est d'une partie du lot 1 A propriété de F.Richard, du point B suivant une clôture séparant le chemin public du lot 1 A dans une direction nord-est une distance de 147 pieds au point C, ou commence la propriété vendue par les présentes.Du point C suivant la même clôture dans une direction nord-est une distance de cinquante pieds au point D de là dans une direction nord-ouest une distance de cent pieds au point E, de là dans une direction sud-ouest une distance de cinquante pieds au point F, de là dans une direction sud-est une distance de cent pieds au point C point de départ.Contenant en superficie 4800 pieds carrés plus ou moins avec les bâtisse y érigées » Avis au défendeur Pour être vendu au bureau d'enregistrement à Mani-waki, district de Labelle, LUNDI, le SEPTIÈME jour de JANVIER 1974, à DEUX heures de l'après-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Roland Matte.District de Labelle.54942-0 land may be more particularly described as follows: Bounded on the east by the public road and on all other sides by the remainder of said lot 1 A.Range 2.Commencing at point A shown on the attached plan and signed for identification by the said parties before the undersigned notary, being the southeast corner of lot 1 A at the point where the dividing line between Ranges A and 2 meets the public road.From point A along the public road in a northeasterly direction over a distance of 988 feet to point B, being the northeast corner of a part of lot 1 A, belonging to F.Richard, from point B along a fence separating the public road from lot 1 A in a northeasterly direction over a distance of 147 feet to Point C, being the starting point of the property hereby sold.From point C along the same fence in a northeasterly direction over a distance of fifty feet to point D; thence in a northwesterly direction over a distance of one hundred feet to point E; thence in a southwesterly direction over a distance of fifty feet to point F; thence in a southeasterly direction over a distance of one hundred feet to point C, being the starting point.Covering a surface area of 4,800 square feet, more or less, with the buildings erected thereon.\" Notice to the defendant To be sold at the Maniwaki Registry Office, District of Labelle.on MONDAY, the SEVENTH day of JANUARY 1974, at TWO o'clock in the afternoon.Roland Matte, Sheriff's Office, Sheriff.District of Labelle.54942 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Québec ( CICO INC., corporation lé-C.S.M.: 18-001205-73.S gaiement constituée, ' ayant sa place d'affaires à 3280 Boulevard Ste-Anne, Giffard, district de Québec, demanderesse, M J.A.ST-ANDRÉ, domicilié et résidant à 2057 boul.Edouard-Montpetit, app.11, à Montréal, défendeur.« Un emplacement situé à 9319A, Boul.Gouin Est, Rivière-des-Prairies, en la Ville de Montréal, connu et désigné comme étant le lot numéro cent cinquante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent trente-deux (132-151) aux plan et livre de renvoi officiels delà Paroisse St-Joseph-de-la-Rivièrc-de.vPrairies, avec bâtisses, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, cambre 56, le TROISIÈME jour de JANVIER 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Pail St-Maktin.Montréal, ce 19 novembre 1973.54953-o MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Québec C CICO INC., a corporation S.C.M.: 18-001205-73A *-> legally incorporated, hav-' ing its place of business at 3280 Ste.Anne Boulevard.Giffard, District of Québec, plaintiff,/.* J.A.ST.ANDRÉ, domiciled and residing at 2057 Édouard-Montpetit Boulevard, Apartment 11, in Montreal, defendant.\"An emplacement located at 9319A Gouin Boulevard East, Rivière-des-Prairies, in the City of Montreal, known and described as being lot number one hundred and fifty-one of the official subdivision of original lot number one hundred and thirty-two (132-151) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Joseph-de-la-Rivière-des-1'rairies, with buildings, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House, in the City of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the THIRD day of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Pall St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 19, 1973.54953 7204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.iS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"DANQUE DE MONTREAL, deman-No 760 957.< deressc vs B.PETER ZULIANI, ' défendeur.Un immeuble composé de,.« 1.Un certain emplacement situé à Senneville, comté de Jacques-Cartier, connu et désigné comme étant le lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-trois (23-1) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, mesurant cent un pieds de largeur en front sur le Chemin Senneville, quatre-vingt-trois pieds de largeur en arrière, sur deux cent vingt et un pieds de profondeur dans sa ligne du côté sud-est et cent quatre-vingt-cinq pieds et soixante-quinze centièmes de pied de profondeur dans sa ligne nord-ouest, le tout mesure anglaise.Avec maison dessus érigée portant le numéro civique 3, Chemin Senneville.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble, sans exception ni réserve, et notamment avec et sujet à la servitude de droit en vue enregistrée sous le numéro 1372894 et à la servitude de droit de passage enregistrée sous le numéro 387804.2.Un emplacement vacant situé dans le village de Senneville, dans le comté de Jacques-Cartier et composé comme suit: a) du lot numéro un a de la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-trois (23-la) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, comté de Jacques-Cartier, mesurant trente-trois pieds de largeur par cent treize pieds et trois centièmes de pied dans sa ligne nord-ouest, et cent vingt-cinq pieds et neuf dixièmes de pied dans sa ligne sud-est, formant une superficie de trois mille neuf cent quarante-quatre pieds carrés, mesure anglaise.b) du lot numéro deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-trois (23-2) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, mesurant trente-quatre pieds de largeur par cent pieds et six dixièmes de pied de profondeur dans sa ligne nord-ouest et cent treize pieds et trois dixièmes de pied dans sa ligne sud-est, formant une superficie de trois mille six cent trente-trois pieds carrés, mesure anglaise; c) du lot numéro trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-trois (23-3) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Anne, mesurant soixante pieds de largeur par une profondeur de soixante-sept pieds, formant une superficie de quatre mille vingt pieds carrés, mesure anglaise.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de justice en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le TROISIÈME jour de JANVIER 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Palais de justice, Paul St-Martin.Montréal, ce 19 novembre 1973.54951-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C RANK OF MONTREAL, plaintiff.No.760 957.-J *J versus B.PETER ZULIANI, de-\\ fendant.An immoveable consisting of .\"1.A certain emplacement located in Senneville, County of Jacques-Cartier, known and described as lot number one of the official subdivision of original lot number twenty-three (23-1) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Anne, measuring one hundred and one feet in width in front on Senneville Road, eighty-three feet width at rear, by two hundred and twenty-one feet in depth on its line on the southeast side and one hundred eighty-five and seventy-five hundredths feet in depth on its northwest line, the whole in English measure.With a house erected thereon bearing civic number 3 Senneville Road.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable, without any exception or reservation, and namely with and subject to the servitude of right of view registered under number 1372894 and to the servitude of right of wav registered under number 387804.2.A vacant emplacement located in the Village of Senneville, in the County of Jacques-Cartier and made up of the following: (a) Lot number one a of the official subdivision of original lot number twenty-three (23-la) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Anne, County of Jacques-Cartier, measuring thirty-three feet in width by one hundred thirteen and three hundredths feet on its northwest line, and one hundred twenty-five and nine tenths feet on its southeast line, having a surface area of three thousand nine hundred and forty-four square feet, English measure.(6) Lot number two of the official subdivision of original lot number twenty-three (23-2) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Anne, measuring thirty-four feet in width by one hundred and six tenths feet in depth on its northwest line and one hundred thirteen and three feet on its southeast line, covering a surface area of three thousand six hundred and thirty-three square feet, English measure.(c) Lot number three of the official subdivision of original lot number twenty-three (23-3) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Anne, measuring sixty feet in width by a depth of sixty-seven feet, covering a surface area of four thousand and twenty square feet, English measure.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House of the City of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the THIRD day of JANUARY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office.Paul St-Martin, Court House, Assistant Sheriff.Montreal, November 19, 1973.54951 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n\" 48 7205 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l A RCADE PILOTE LIMITEE, No 05-004722-73A corporation légalement cons- ' tituée, ayant sa place d'affaires au no 10505 Boul.d'Auteuil, Montréal dit district, demanderesse, vs MARCEL GIRARD, domicilié et résidant au 3050 rue Ramsay, Duvernay, Laval, district de Montréal, défendeur.« Un emplacement situé sur Hôtel de Ville, en la Cité de Montréal, mesurant quarante-deux pieds et six pouces de largeur sur une profondeur de quatre-vingt-sept pieds et six pouces, mesure anglaise et plus ou moins, et composé de la subdivision numéro cent soixante-deux du lot originaire numéro cent trente-sept (137-162) du cadastre officiel du Village de la Côte St-Louis.Avec maisons dessus érigées portant les numéros civiques 4554 et 4560 rue Hôtel de Ville.Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, pouvant affecter ledit immeuble.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATRIÈME jour de JANVIER 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, CourSupêreure, Paul St-Martin.Montréal, ce 19 novembre 1973.54950-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal / rvAME ADELINE MERCIER, No 05-003 177-72,1 épouse commune en biens ' de Roger Denault, domiciliée et demeurant au 68, 3e Avenue, à Greenfield Park, district de Montréal, demanderesse, vs ROGER DENAULT, domicilié et demeurant au 895 avenue Victoria, à St-Lambert, district de Montréal, défendeur.« Un immeuble situé à St-Lambert, connu et désigné comme étant une partie du lot No soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent cinquante-six (256-ptie.78) et parties des lots Nos vingt-six et vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent cinquante-sept (257-26 et 27 pties.) au cadastre officiel de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil, division d'enregistrement de Chambly; ledit emplacement mesurant quatre pieds et cinq dixièmes de pied (4.5') dans sa ligne nord-est, cent pieds (100') dans sa ligne nord-ouest et cent cinq pieds et six dixièmes de pied (105.6') dans sa ligne-sud-ouest et borné comme suit: Vers l'est: par la rue Victoria.Vers le nord-est: par la rue St.Lawrence.Vers le nord-ouest: par d'autres parties des lots 256-78 et 256-26 et 27; Vers le sud-ouest: par parties des lots 258-141, 142, 143 et 144.Avec la maison dessus construite et portant le numéro domiciliaire 805 de la rue Victoria à St-Lambert.» Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal / A RCADE PILOTE LIMITEE.No.05-004722-73A * * a corporation legally incor-y porated having its place of business at 10505 d'Auteuil Boulevard, Montreal said district, plaintiff, vs MARCEL GIRARD, domiciled and residing at 3050 Ramsay Street, Duvernay, Laval, District of Montreal, defendant.\"An emplacement located on City Hall, in the City of Montreal, measuring forty-two feet and six inches in width by a depth of eighty-seven feet and six inches, English measure and more or less, and consisting of subdivision number one hundred sixty-two of original lot number one hundred thirty-seven (137-162) on the official cadastre for the Village of Côte St.Louis.With the houses erected thereon bearing civic numbers 4554 and 4560 on City Hall Street.As the whole presently subsists with all active and passive, apparent and unapparent servitudes that may affect said imoveable.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House of the City of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FOURTH dav of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Deputy Sheriff.Montreal, this 19th of November, 1973.54950 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal f-WRS.ADELINE MERCIER, No.05-003 177-72A *V* wife common as to property ' of Roger Denault, domiciled and residing at 68 - 3rd Avenue, in Greenfield Park, District of Montreal, plaintiff, vs ROGER DENAULT, domiciled and residing at 895 Victoria Avenue, in St.Lambert, Districtof Montreal, defendant.\"An immoveable located in St.Lambert, known anil described as being a part of lot No.seventy-eight of the official subdivision of original lot number two hundred fifty-six (256-Pt.78) and parts of lots numbers twenty-six and twenty-seven of the official subdivision of original lot number two hundred fifty-seven (257-26 and 27 Pts.) on the official cadastre of the Parish of St.Antoine-de-Longueuil, Chambly Registration Division; the said emplacement measuring four and five tenths feet (4.5') on its northeast line, one hundred feet (100') on its northwest line and one hundred five and six tenths feet (105.6') on its southwest line and bounded as follows: Towards the east : by Victoria Street.Towards the northeast: by St.Lawrence Street.Towards the northwest: by other parts of lots 256-78 and 256-26 and 27; Towards the southwest: by parts of lots 258-141, 142, 143 and 144.With the house erected thereon and bearing domiciliary number 805 of Victoria Street in St.Lambert.\" 7206 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973.Vol.105, No.48 Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, à 201, Place Charles Lemoyne, Édifice Montval, à Longueuil, P.Q., le QUATRIÈME jour de JANVIER 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 19 novembre 1973.54952-0 RICHELIEU Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Richelieu 1 \"DANQUE DE COMMERCE CANA-No 21-584.< D DIENNE IMPERIALE, corpora-\u2022 tion constituée, ayant son siège social et sa principale place d'affaires au 1155 ouest, Boulevard Dorchester, cité et district de Montréal, demanderesse, vs GILLE POT VIN et NICOLE POTVTN, défendeurs.« Une maison mobile et un terrain situés au 92, Rang Ste-Thérèse, St-Pierre de Sorel, cadastre partie 231 de la corporation municipale de la paroisse de St-Pierre de Sorel.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Sorel, à Sorel, District de Richelieu, P.Q.VENDREDI, le QUATRIÈME jour de JANVIER 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif Ad Hoc, Palais de Justice, Mercier Grégoire.Sorel, le 16 novembre 1973 .54905-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour supérieure \u2014 District de Montréal ( T ES PLACEMENTS A.J.P.No.05-004218-73.S *-> LIMITEE, corps politique et ' incorporé, dûment constitué selon la loi, ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, demandeur, vs ROGER GAUTHIER, de St-Amable, district de Richelieu, résidant et domicilié au numéro civique 757, rue Joliette, défendeur, et ARMAND WAELPUT, en se qualité de REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Verchères, mis en cause.« Un terrain situé en la paroisse de St-Amable, connu et désigné comme étant la subdivision un du lot sept (7-1) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Marc.Avec la maison y érigée en cours de construction.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Verchères, à Verchères.district de Riche-lieu, P.Q., VENDREDI, le QUATRIÈME jour de JANVIER 1974, à DEUX heures de l'après-midi.Bureau du shérif Shérif Ad Hoc, Palais de Justice Mercier Grégoire.Sorel, 17 novembre 1973.54904-o To be sold at the Registry Office of the County of Chamblv, at 201 Place Charles Lemoyne, Montval Building, in Longueuil, P.Q., on the FOURTH day of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 19, 1973.54952 RICHELIEU Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Richelieu t CANADIAN IMPERIAL BANK OF No.21-584.S COMMERCE, an incorporated ' corporation, having its head office and its principal place of business at 1155 Dorchester Boulevard West, in the City and District of Montreal, plaintiff, vs GILLE POTVIN and NICOLE POTVIN, defendants.\"A mobile home and a piece of land located at 92 Ste.Thérèse Range, in St.Pierre-de-Sorel, cadastral part 231 of the Municipal Corporation of the Parish of St.Pierre-de-Sorel.\" To be sold at the Sorel Registration Division Office, in Sorel.District of Richelieu (Québec), on FRIDAY, the FOURTH day of JANUARY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Mercier Grégoire.Court House, Sheriff Ad Hoc.Sorel, November 16, 1973.54905 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( T ES PLACEMENTS A.J.P.No.05-004218-73A J-' LIMITEE, a body politic ' and corporate, duly incorporated according to law, having its head office and principal place of business in the Citv and District of Montreal, plaintif, m ROGER GAUTHIER, of St.Amable, District of Richelieu, therein domiciled and residing at civic number 757 Joliette Street, défendent, and ARMANI) WAELPUT, in this quality of REGISTRAR for the Verchères Registration Division, mis en cause.\"A piece of land located in the Parish of St.Amable, known and described as being subdivision one of lot seven (7-1) on the official plan and in the book of reference for the Parish of St.Marc.With the house under construction being erected thereon.\" To be sold at the Verchères Registration Division Office, at Verchères, District of Richelieu, Québec, on FRIDAY, the FOURTH day of JANUARY, 1974, at TWO o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Grégoire Mercier, Court House.Sheriff Ad Hoc.Sorel, November 17, 1973.54904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1er décembre 1973, 105' année, n\" 48 7207 Erratum CENTRE DE PHYSIATRIE COTE DES NEIGES INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, sous l'autorité de l'article 12 de la Loi des compagnies, donne avis qu'il a corrigé le 12 novembre 1973 les lettres patentes émises le 21 juin 1972.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.54865-0 723495 Erratum CENTRE DE PHYSIATRIE COTE DES NEIGES INC.The minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives give notice that, on November 12, 1973, under section 12 of the Companies Act, he corrected the letters patent issued on June 21, 1972.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.54865 723495 7208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1st, 1973, Vol.105, No.48 INDEX No 48 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Association cooperative
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.