Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 15 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-12-15, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE QUÉBEC OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES 15 DECEMBRE 1973 N° 50 7343 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, IB décembre 1973, 10b' année, n° 50 7345 PARTIE 1 PART 1 fine© G 3/ PLU 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière «l'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.l.a Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément fau Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La par-à tie 1 paraît le samedi matin et contient desavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés «le les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publicati«>n de certains avis, à cause de leur longueur ou pour «les motifs «l'administration.4.Imlkpjcr le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas.l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement «loit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Editeur officiel du Québec a le droit «le retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazelle, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazelle is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazelle.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they arc to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Quebec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazelle (part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHAItLES-HENKI DUBÉ, Québec Official Publisher 7346 QUÉBEC OF E ICI M.OA/.ETTE, December 15, 1973, Vol.105, So.60 TARIF DES ANNONCES.ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de nom1., de chilîres.etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes «l'abonnement (Partie 1): «lu 1er janvier au 31 décembre.S20: du 1er avril au 31 décembre.SIS et du 1er juillet au 31 «lécembre.$10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au lias îles avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro île facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette |>our la première insertion: le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que In matière n'est ni de notre ootn|>osition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que «le notre numéro «le facture.L'Editeur officiel du Québec.Charles-HexKi Dvbk.Cité Parlementaire.Québec.25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods (Part I): from 1 January to 31 December.$20.from 1 April to 31 December.S15 and from 1 July to 31 December.S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Cazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dibé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec.October 25.1972.Pour toute demande renseignements concernant For information concerning the publication of publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la notices, off-prints or subscription rates to the Québec Gazelle uffirielle du Québec, veuillez communiquer avec: Official (Gazelle, please call: Georges l-apierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire.Quebec G1A 1G7, P.O.Georges Lapierrc Québec Officiai Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec I Uli.i.il Publisher, Parliament Buildings.Québec GIV IG7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n' 107) Postage piid-in-cnsh \u2014 Thir«l class matter (permit Nn.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année, n° 50 7347 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Xante of Ihe company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.E.C.CORPORATION INC.A.X.ELECTRONICS CORP.AGENCE MUSICALE INTERNATIONALE INC.LES AGENCES LEO GAUTHIER INC.AGENCES M.GUAV INC.LES AGENCES MUSICALES SAGUENAY LAO ST-JEAN LTEE AGENCES TOURISTIQUES CARTIER INC.AHUNTSIC PLUMBING & HEATING CO.LTD.L'AIDE AU FOYER INC.ALLMARK INVESTMENT LTD.AMENAGEMENTS BAIE PLAISANCE INC.L'ARCHE DES JEUNES.LES ARCHERS LAURENTIENS.ARDEN CONSTRUCTION CO.LTD.ARENA DE LA RIVE SUD INCORPOREE.ARESVILLE GARDENS INC.ARGENTEUIL EQUIPMENT LIMITED.ARGUS PRESS CORP.ARIL HOLDINGS INC.ARMOIRES DE LUXE INC.ARNEL COMMERCIAL ENTERPRISES LTD.LES ARTS FEMININS DE LA MAURICIE INC.ARVTDA TENNIS CLUB INC.ASSOCIATION DU BASEBALL DE ST-HVACINTHE INC.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1969 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1967, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Aima.1970 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963.1969, 1971 à/to 1973 incl.Rosemont.1972, 1973 Montreal.1972, 1973 .Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Joliette.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Laprairie.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Lachute.1969, 1970, 1972, 1973 Montreal.1972.1973 Montreal.1972.1973 Ville d'Anjou.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Shawinigan.1972.1973 Arvida.1967, 1971 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1972,1973 7348 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1.5, 1973.Vol.105.So.50 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ASSOCIATION DE CAMPING DE CHANDLER INC.ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE DU SERPENT NOTRE-DAME DU LAUS QUE ASSOCIATION DES CITES DES JEUNES DU QUEBEC.L'ASSOCIATION DES CLUBS DE SERVICE DU QUEBEC METROPOLITAIN INC.L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS AVERTIS.ASSOCIATION DE DANSE A D R Q .L'ASSOCIATION DIOCESAINE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU DIOCESE DE TROIS-RIVIERES INC.L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU CEGEP DE THETFORD INC.ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DU COLLEGE DE JONQUIERE ASSOCIATION DES GROUPEMENTS EN ALIMENTATION INC.ASSOCIATION JEUNESSE ET CULTURE DU QUEBEC.ASSOCIATION DES LOISIRS DU LAC ROND INC.L'ASSOCIATION NAUTIQUE DU LAC BLEU INC.L'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC.ASSOCIATION PARENTS-MAITRES, ST-GEORGES INC.ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CINEASTES.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DES CHALETS DES EBOULIS INC.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC BISBAY .ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES I\"' LAG MATA .M HI N L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC VERT INC.ASSOCIATION REGIONALE DE NATATION AMATEUR RIVE SUD METROPOLITAINE ASSOCIATION SPORTIVE « LES CANADIENS DE L'ILE BIZARD INC.» ASSOCIATION TROIS CAP.ASSURANCES PIERRE ALIX INC.AIBERGE DES PINS LAC ST-JOSEPH INC.LES AUBERGES DE JEUNESSE DU QUEBEC.CLAUDE AUBIN LTEE.AUTO C.O.V.INC.AUVICOM INC.AVIAN DEVELOPMENT CORPORATION.AYOTTE & LAMBERT INC.B.G.L.INC.Chandler.1969 à/to 1973 incl.St-Pierre.1968 à/to 1973 incl.Hull.1967 à/to 1973 incl.Québec.1967.1968.1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1969 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1972, 1973 Jonquitre .1967 à/to 1973 incl.Jonquiére 1972.1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.St-Calixte.1970 à/to 1973 incl.St-Dunstan-du-Lac 1970 à 1973 incl.Beauport Pont Viau.1969 à/to 1973 incl.St-Georges.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Ste-Victoire 1969, 1971 à/to 1973 incl d'Arthabaska St-Joseph-de-Coleraine 1972, 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Lac Vert.1968 à/to 1973 incl.Lognueuil.1972.1973 St-Haphaël-de-L'lle 1972, 1963 Bizard Cap-de-la-Madeleine .1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Fossambautt-sur-le-lur .1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1969 à/to 1973 incl.Laval.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972 à/to 1973.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Berthierville.1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7349 Nom de la compagnie Name of the company B.H.CONSTRUCTION INC.B.L.M.CONSTRUCTION INC.B.L.R.LANGUAGE SCHOOLS LTD.B.T.H.CONSTRUCTION LTEE .LA BAIE DU NOliD FOURRURES INC.YVES BAILLARGEON LTEE.BARKUN INSURANCE SERVICES INC.LES BARONS DE ROUYN-NORANDA .BARRIF LTD.BAYCO INC.BEACONSFIELD CLUB SHARES LIMITED.CHARLES A.BEAUDIN INC.BEAULE TUILE ET TAPIS INC.ROCH BELLEMARE INC.BERKSHIRE CONSTRUCTION CORP.BETON MINVILLE INC.BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE PRET DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN.SAMUEL BIDNER INC.BIENCO LTEE.BIG VALLEY LIVESTOCK EXPORTERS INC.BILRAL INC.BIRMOSS PARK LIMITED.BLACKSTONE BUILDING CORPORATION.THE BLACK AND GOLD ATHLETIC ASSOCIATION INC LOU BLACK'S LIVING ROOM '67' INC.F.W.BLANCHARD INC.GERARD BLANCHET INC.LE BLE D'INDE PAYSAN INC.BLEVINAL BOARDING HOME INC.BLOCS DE CIMENT ST-JEAN INC.BLONDIN LEASING INC.BLOOMFIELD AGENCIES LIMITED.BLUMER REALTIES INC .Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Montreal.1972, 1973 Montréal.1971 à/to 1973 incl.Al ma.1969 à/to 1973 incl.St-Lambert.1972, 1973 Montreal.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Noranda.1968 à/to 1973 incl.Shawville.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1962, 1963, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Agathe.1967 à/to 1971 incl.Marieville .1967 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1967 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Alma.1972,73 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Beauport.1965à/to 1967 incl., 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1961, 1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964,1972,1973 Westmount.1959.1965,1966.1969 à/lo 1973 incl.Verdun.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Mont-Roval.1962 à/to 1964 incl., 1968 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.L'Assomption.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 St-Jean.1968, 1971 à/to 1973 incl.Hull.1965.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal .1971 à/to 1973 incl. 7350 QVFJiEi OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.\t\t.Vo.50 Nom de la compagnie\tAdresse\tRapporta non produits Same of the company\tAddress\tReturns not filed \t\t1967, 1969 a/to 1973 incl.LA BOHEME HAUTE COIFFURE INC.\t\t1969 à/to 1973 incl.BONA VENTURE HOLDINGS LIMITED\t\t1972, 1973 \t\t1962, 1966.1970 à/to \t\t1973 incl.\tRivière-du-Loup.\t1971 à/to 1973 incl.\tAylmer.\t1969 à/to 1973 incl.BOUTIQUE AU VIEUX G KENT EU INC.\t\t1971 à/to 1973 incl.BOUTIQUE CORINNE DE FRANCE LTEE.\tMontreal.\t.1971 à/to 1973 incl.\tMontreal .\t1967 à/to 1973 incl.BOUTIQUE TAJ-MAHAL LTEE .\t\t1072.1973 BOUTIQUES PLATEAU MONT ROYAL INC .\tMontréal .\t1966 à/to 1973 incl.MAURICE BRAULT JOAILLIER INC.\tMontréal.\t1968.1971 à/to 1973 incl.C.A.T.A.(L'AGE D'OR).\tVille-Marie.\t1972, 1973 C'.L.P.S.INC.\t\t1972, 1973 CADET CLEANERS LIMITED .\t\t1971 à/to 1973 incl.\t\t1968 à/to 1973 incl.\t\t1966.1970 à/to 1973 incl.CENTRAL LAND & DEVELOPMENT CORPORATION.\tWaterloo.\t1971 à/to 1973 incl.CENTRE D'ACHAT DUBERGER INC.\tQuébec.\t1968 à/to 1970 incl.CENTRE ASTRONOMIQUE DE MONTMAGNY INC.\tMontmagny.\t.1970 à/to 1973 incl.\t\t1969 à/to 1973 incl.LE CENTRE COLOMBIEN SAINTE-FOY INC.\tSte-Foy.\t.1968 à/to 1973 incl.\tQuébec.\t1971 à/to 1973 incl.CENTRE LOISIRS DANSE BAIE DES CHALEURS\t\t1972.1973 CENTRE DU SOULIER ITALIEN INC.\t\t1970 à/to 1973 incl.CERCLE D'ETUDES EN CONDUITE AUTOMOBILE (C.E.C.A.)\t\t1971 à/to 1973 incl.\tTrois-Rivicrcs\t1969 à/to 1973 incl.LA CHANSON DU QUEBEC INC.\t\t.1964 à/to 1973 incl.LES CHAUSSURES LE GENTILHOMME LTEE .\t\t.1971 à/to 1973 incl.CHAUSSURES MASSY INC.\tMontréal.\t1970 à/to 1973 incl.\tSt-Basile-le-Grand .\t1972.1973 \tSte-Anne-de-Bellevue\t.1967.1969 a/to \t\t1973 incl.\tMontréal.\t1972, 1973 CINEDOME THEATRES LTD.\t\t1970 à/to 1973 incl.CITADEL SALVAGE CORPORATION.\tQuébec.\t1961, 1966.1969 à/to \t\t1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7351 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed THE CITADEL STEAK HOUSE INC.CITE DES JEUNES DE HULL.CITY EDIBLE REFINING LTD.CLUB AU RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS (LAC CACHE) INC.CLUB AUTOMOBILE BOMBARDIER.CLUB AUTO-NEIGE EM-BO DE ROUYN NORANDA INC.CLUB AUTO-NEIGE DE STE MARIE INC.CLUB D'AVIATION DE TROIS RIVIERES INC.CLUB D'AVIRON DE L'EQUIPE DU QUEBEC INC.LE CLUB DE BASEBALL LES SAINTS DE SAINTE-THECLE INC.CLUB BI-CLOU-ITL .CLUB DE CHASSE & PECHE LACHAINE.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE ST GERMAIN DES MONTS CLUB DES 50 INC.CLUB FONTAINE INC.CLUB DE HOCKEY LES BARONS DE GRANBY INC.CLUB DU LAC DU REPOS.CLUB DU LAC VERNON INC.CLUB DE MOTO-NEIGE LES ETOILES DES PINS INC.CLUB OPTIMISTE LORETTE.CLUB PARC DUCHESNEAU.LE CLUB DE PECHE DU LAC LA JUSTONE INC.CLUB DES PLAINES INC.CLUB LE RACCOURCI INC.CLUB DES RAQUETTEURS (TIKOUAPE) INC.CLUB RECREATIF JOKO INC.CLUB RICHELIEU DE GATINEAU.CLUB LA ROSE DES VENTS DU QUEBEC METROPOLITAIN INC.LE CLUB DE SKI DE GASPE INC.CLUB SPORTIF BLANC-ROUGE-VERT INC.CLUB SPORTIF POCOMOCO INC.LE CLUB SPORTIF DE VICTORIAVILLE INC.CLUB DE TENNIS DE MATANE.CLUB DE TENNIS (ST-ISIDORE INC).CLUB TROIS RIVIERES ARCHERS.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Hull.1964, 1966.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Chibougamau.1972.1973 Valcourt.1970 à/to 1973 incl.Noranda.1972.1973 Ste-Marie.1965 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1972, 1973 Montréal.1972, 1973 Ste-Thecle.1967.1970 à/to 1973 incl.Ste-Thérêse.1963 à/to 1965 incl., 1973 St-Pierre-de-Wakefield.1964 à/to 1973 incl.Giffard.1971 à/to 1973 incl.Thurso.1972, 1973 Les Escoumins.1960 à/to 1973 incl.Granby.1972, 1973 St-Eusébe.1971 à/to 1973 incl.Verdun.1962 à/to 1973 incl.Deauville.1972.1973 Ancienne-Lorette.1970 à/to 1973 incl.Armagh.1971 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Québec.1956 à/to 1973 incl.Forestville.1958 à/to 1973 incl.Aima.1968 à/to 1973 incl.Ste-Croix.1971 à/to 1973 incl.Gatineau.1967.1968, 1970 à/to 1973 incl.Neufchâtel.1966 à/to 1973 incl.Gaspé.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Basile.1973 Victoriaville.1968 à/to 1973 incl.Matane.1956, 1969 à/to 1973 incl.St-Isidore.1962 à/to 1973 incl.T rois-Rivières.1971 à;to 1973 incl. 7352 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.No.50 Nom de la compagnie Name of the company\tAdresse Address\tRapports non produits Returns not filed \tSorel.\t1959 à/to 1973 incl.LOUIS COMEAU INC.\t\t1971 à/to 1973 incl.COMITE DES CITOYENS DE TROIS RIVIERES.\tTrois-Rivirres.\t1970 à/to 1973 incl.COMITE DES LOISIRS DES TROIS RUISSEAUX INCORPOREE\tI/Anse-au Griffon.\t1969 à/to 1973 incl.COMPAGNIE DE CHAUSSURES PAJAR LTEE .\tMontreal.\t1964, 1970 à/to 1973 incl.LA COMPAGNIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION INC\t\t1970 à/to 1973 incl.COMPTOIR AGRICOLE ST LOUIS INC.\tSt-Louis-de-Gonzague .\t.1972, 1973 LE CONCILE DES JEUNES DE SAINT HYACINTHE.\tSt-Hyarinthe.\t1973 CONSEIL REGIONAL DE BIEN-ETRE DE SHERBROOKE\tSherbrooke\t1967 à/to 1973 incl.CONSTRUCTION GENERALE.SI'HEX LTEE.\tMontréal.\t1971 à/to 1973 incl.CONVENCO OF CANADA LIMITED .\t\t1970 à/to 1973 incl.CORKO LTEE.\tSherbrooke.\t1968 à/to 1973 incl.CORNUCUPIA INVESTMENTS LTD.\t\t1967 à/to 1973 incl.\t\t1966.1970 à/to \t\t1973 incl.CORPORATION IMMOBILIERE B.& J.INC.\tSt-Laurent.\t1965 à/to 1973 incl.LES CREDITS VAL-MONT INC.\tMontréal.\t1965.1966, 1973 LES CYCLONES DE WARWICK .\t\t1966 à/to 1973 incl.\tMontreal.\t1970 à/to 1973 incl.1970 à to 1973 incl.DR.ROLLING METAL INC.\tCap-dc-la-Madeleine.\t \t\t1972, 1973 1964 à to 1971 incl.1965 à/to 1973 incl.DECOR METAL LTD.\t\t \tMontreal.\t DELTA TECHNIQUES LTD.\t\t1968 à/to 1973 incl.DERBY POP CORN INC.\tMontréal.\t1961 à/to 1973 incl.BERNARD DIGUER 5-10-15 INC.\tDonnacona.\t1962, 1964 à/to 1973 incl.DISCOUNT ISTA-PRINTS (D.I.P.) INC.\t\t1971 à/to 1973 incl.DISTRIBUTION ELITE LTEE.\tMontréal.\t1962, 1968 à/to 1973 incl.\t\t1972.1973 \tMontréal.\t1973 DOWNCASTER DEVELOPMENT INC.\t\t1969 à/to 1973 incl.\tDrummondviUe.\t1971 à/to 1973 incl.DROMO INC.\tL'Ancienne-Lorette.\t1971 à/to 1973 incl.WAITE DUFAULT MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY)\tDuparquet .\t1971 à/to 1973 incl.IHTRESNE, McLAGAN.DAIGNAULT INC.\t\t1972.1973 DUNN ENTERPRISES INCORPORATED\tMontreal .\t1960 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7353 Nom de la compagnie Name of the company DWELLING LOCATION SERVICE LTD.E.T.SPECIALTIES INC.ECOLE THERESE GAUTHIER INC.ECOLOG-MOTIVATION INC.ECONAR CONSTRUCTION INC.EDIFICE TREVER INC.ELGAR MINING CORP LIMITED.EM-AR DEVELOPMENT CORP.ENTREPRISES ARC INC.LES ENTREPRISES ARMAND VADEBONCOEUR LTEE.LES ENTREPRISES BLB INC.ENTREPRISES BOCAR INC.LES ENTREPRISES G & C INC.LES ENTREPRISES G.M.M.INC.ENTREPRISES H.O.M.LTEE.ENTREPRISES HOSPITALITE LIMITEE.LES ENTREPRISES J.J.S.INC.LES ENTREPRISES JOLADES INC.LES ENTREPRISES L.P.B.INC.LES ENTREPRISES LABRANCHE INC.LES ENTREPRISES LAFLEUR (1961) LTEE.LES ENTREPRISES LALLOUZ INC.LES ENTREPRISES LAURV INC.LES ENTREPRISES MAUPIER INC.LES ENTREPRISES MAUROG INC.LES ENTREPRISES DE MEUBLES LUC G EN EST INC.LES ENTREPRISES MONT-PLAISANT INC.LES ENTREPRISES THOMAS INC.EPICERIE SAVARD & FILS LIMITEE.EQUIPEMENT B.C.INC.EURO-STUDIO LIMITEE.FAIRWINDS CORPORATION LTD.FAVRE & FILS LIMITEE.ERNEST FIEDERER SALES INC.FONDATION ARTISTIQUE DE SAINT-JEAN.FONDS MASKA LIMITEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1958, 1968.1969, 1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1966.1967, 1970 à to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Levis.1972,1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal .1972.1973 Côte St-Lue.1969 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.La Tuque.1965.1967.1969, 1971 à/to 1973 incl.St-Laurent.1968, 1972, 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Brassard.1972.1973 Hull.1972.1973 Laval.1969 à/to 1973 incl.St-Jean.1969 à,to 1973 incl.Amos.1966.1971 à to 1973 incl.Beauharnois.1967 à/to 1973 incl.Granby.- 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1971 à to 1973 incl.Sherbrooke.1962, 1967 à,to 1973 incl, Magog.1971 à/to 1973 incl.Québec.1960 à/to 1973 incl.St-Sulpice.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Chicoutimi.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1964 à/to 1973 incl.St-Jean.1971 à/to 1973 incl.St-Joseph.1973 7354 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 15.1973, Vol.105.So.50 Nom de la compagnie\tAdresse\tRapports non produits Name of the company\tAddress\tReturns not filed EDGAR FORCIER & FILS INC.\tMontréal.\t1970 à/to 1973 incl.4 SEASONS DRIVE IN (MASSON) LTD.\t\t1968.1969.1971 à/to \t\t1973 incl.FOURNITURES CHIRURGICALES DU QUEBEC LTEE.\t\t1968 à/to 1973 incl.\tHinchinbrooke.\t1967.1968.1970 à/to \t\t1973 incl.\t\t.1969, 1971 à/to 1973 incl.\tMontreal.\t1972, 1973 \tVictoriaville.\t1969, 1970, 1972.1973 \t\t1968 à/to 1973 incl.G.T.TRANSPORT INC.\tLaval.\t1968.1969, 1972, 1973 \t\t1971 à/to 1973 incl.\t\t1964 à/to 1973 incl.\t\t1971 à/to 1973 incl.GARTHBY TRANSPORT LIMITEE.\t\t1970 à/to 1973 incl.\t\t1969 à/to 1973 incl.\tMontréal.\t1967 à/to 1973 incl.\t\t1966 à/to 1973 incl.GELINEAU AUTO PARTS INC.\tSte-Brigide.\t.1964 à/to 1973 incl.GENAT DEVELOPMENTS LTD.\tMontreal.\t1966 à/to 1973 incl.\tSt-Jean-de-Mat ha\t1972.1973 GENERIC PHARMACEUTICALS LTD.\tQuébec.\t1972.1973 \t\t.1966 à/to 1973 incl.\t\t1969 à/to 1973 incl.GERARD INVESTMENTS INC.\t\t1967 à/to 1973 incl.STEPHEN GERO REALTIES INC .\tMontreal.\t1964 à/to 1973 incl.\tTrois-Rivicres.\t.1970 à/to 1973 incl.\t\t1972 et 1973 \tShawinijian Falls.\t1969 i/lo 1973 in-l.\tMontreal.\t1970 à/to 1973 incl.GORDONIA LTD.\t\t1171 V'to 1Q73 inrl \t\ts v w ¦ Of Iv 1 cl U Hill* 1966 à/to 1973 incl GRANBY SPINNING MILLS LTD.\t\t.1965 à/to 1973 incl.GRAND CONSTRUCTION LTD.\t\t1969 à/to 1973 incl.GRAND PAVILLON (HULL) INC.\tHull.\t1968 à/to 1973 incl.GRAND TEMPLE PYTHIAN SISTER (P.S.) OF QUEBEC\t\t1966 à/to 1973 incl.\t\t1970 à/to 1973 incl.GRANGE 32 INC.\t\t1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7355 Nom de lu compagnie Name of the comjiaiiy Adresse Address Rapports non produits Returns not filed GREEK PROGRESSIVE ASSOCIATION OF CANADA INC.GREEK RADIO WIRE PROGRAMS INC.GREENPARK CONSTRUCTION CO.LTD.JEAN GRONDIN INC.STANISLAS GRONDIN INC.JACQUES G.GUAY ET ASSOCIES INC.LE GUIDE DE SECURITE INC.GUI-MEL INC.HADJIZADE LAND INC.LUCIEN HAMEL CONSTRUCTION INC.HARUNI METAL PRODUCTS LTD.BERT HARVEY CORPORATION.HELLENIC FOOD INDUSTRIES CO.LTD.HENRI-ETTE DRESS INC.HICKORY' INDUSTRIES INTERNATIONAL SALES CORPORATION.HILLTOP NURSERY AND GREENHOUSES LTD.HOME LAUNDRY MATERIALS OF CANADA INC.HOTEL GEORGE (ROUYNl LIMITEE.HOTEL PAQUET LTEE.HOTEL ROCHER BLANC LTEE.HOTEL ST LOUIS (LA SARRE) INC.HOTEL TAILLEFER ET FILS INC.LES HUILES LAFLAMME INC.I & C CONSTRUCTION INC.LES IMMEUBLES GAUDET INC.IMMEUBLES IMPERIAL CIE LTEE.LES IMMEUBLES LABROSSE INC____ LES IMMEUBLES LADOUMOND INC.IMMEUBLES PIERRE NANTEL INC.IMMEUBLES OUTREMONT REALTIES INC.IMMEUBLES ET PRETS J.P.L.INC.IMPORTATION VOICI INC.INDUSTRIAL TELETYPEWRITER ELECTRONICS CORP.INDUSTRIES GRONDIN & DOUCET INC.INTERNATIONAL CINE CLUB INC.INTERNATIONAL PREMIER PIZZA KING CORPORATION.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Windsor.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970.1973 Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Beaconsfield.1908 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Rooyn.1968 à/to 1973 incl.Shelter Bav.1961, 1963 à/to 1967 incl.1969, 1971 à/to 1973 incl.Sacré-Coeur.1966 à/to 1973 incl.La Sarre.1972 et 1973 Beauharnois.1972, et 1973 Thetford Mines.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Sainte-Agathe-des-Monts 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Longueuil.1971 à/to 1973 incl.Arvida.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1971 incl, 1973 Outremont.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Quebec.1969 à/to 1973 incl. 7356 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 1».1973.Vol.105.No.30 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Val-D'or.1967 a/to 1973 incl.LaSalle.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.St-Antoine.1971 à/to 1973 incl.Looking.1962.1964 à/to 1969, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1971 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1971 à/to 1973 incl.Lyster.1962 à/to 1973 incl.Québec.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1962.1969 à/to 1973 incl.Valcartier.1964 à/to 1973 incl.St-Martin.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1963.1964.1967 à/to 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.(\"harlesbourg.1970 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1961.1963 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1961.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à,to 1973 incl.Montreal.1960.1966.1971 à/to 1973 incl.St-Hubert.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1965 incl.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1962, 1970 à/to 1973 incl.LES INVENTIONS CATIEN & MAJOR LTEE .1 & J PROMOTION INC J.L.JACQUES TRANSPORT INC' J & M LEATHER GOODS LTD.J.M.J.HOLDINGS INC.J.P.B.AUTOMATE INC.JACKSON HARDWARE MFG.LTD.JARRY RESTAURANT INC.JEMONT INC.JETRONICS CORPORATION .JEUNAC INC.LA JEUNE CHAMBRE DE MONT-LAURIER.JEUNE COMMERCE DE LYSTER.LE JEUNE COMMERCE DE QUEBEC OUEST INC.JOA MANAGEMENT LTD.RAY JOBSON INC.JODA INVESTMENT CORP.JOHNSTALL ENTREPRISES INC.JOLIL COMPANY LTD.JOLIN CONSTRUCTION LTEE____ JORO INVESTMENTS LTD.JOSEPH LE TAILLEUR INC.JOURDAIN & LORRAIN INC.LE JOURNAL LA VIE (1969) LTEE.JUNIOR B DE THETFORD INC.JUNIOR HOLDINGS INC.K & M MEAT MARKET INC.KALO REALTIES LTD.KAM SAM CORPORATION.KANASH INVESTMENT CORPORATION.KANAWID INC.KAPRISSE INC.KAREN REALTIES INC.M.KATZINC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7357 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed KEL TAXIS LTD.KELVEN CO.LTD.KEMPSON INC.KERNOR CORPORATION.KESSLER INDUSTRIES INC.KIMPTON DUPUIT AGENCIES LIMITED____ KING KONG CAFE DE THETFORD INC.KIRON INVESTMENT CORPORATION LTD.L.B.SERVICE INC.L & M TRANSPORT INC.L.M.S.CONSTRUCTION INC.L.T.L.INC.LABBE AUTOS (1964) INC.LABELLE ELECTRIQUE INC.LABORAV INC.LABRADOR OIL INC.LABRECQUE & DU TREMBLE INC.LABROSSE EXPANSION BIT CORPORATION.R.LACHAPELLE LTEE.LACHINE MAROONS INC.LACHMAS INVESTMENTS INC.LACOMBE INVESTMENTS INC.J.LACOSTE INC.LADUQUESNE INC.LAFOND & VALDAIS INC.LAKESHORE STRUCTURAL STEEL CO.LTD.LALIBERTE & FILS INC.J.M.LAMBERT AUTOMOBILE INC.LAMBERT CO.LTD.LAMBERT MANAGEMENT CORPORATION.LAMBERT STREET DEVELOPMENT LTD.LAMINCO INC.LAMPERT & CO.LTD.LANBAR CONSTRUCTION CORP.Montreal.1962 a/to 1970 incl.1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Hubert.1960.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.St-Laurent.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1963.1964.1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Liboire.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1969, 1971 à/to 1973 incl.Dorion.1967 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1972 et/and 1973 Victoriaville.1964 à/to 1973 incl.Rosemcre.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montmagny.1972 et/and 1973 Boucherville.1971 à/to 1973 incl.Lafontaine.1963 à/to 1973 incl.St-Yineent-de-Paul.1963 4,'to 1973 incl.Lachine.1961 à/to 1973 incl.Lachine.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Saint-Michel-des-Saint.1972 et/and 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Lachine.1969 à/to 1973 incl.Jonquicre.1964,1967 à/to 1969 incl., 1972 et/and 1973 Shawinigan.1963, 1964, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1970 à/to 1973 incl.Saint-Laurent.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1966 à/to 1973 incl. T.T.s QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 15.1973.loi.105.So.50 Nom de la compagnie .Vamr of the company Adresse Rapports non produits .I'M'\" Returns not filed Montreal.1908 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à,to 1973 incl.Montreal .1969 à/to 1973 incl.Laval.1968.1972 et/and 1973.Montreal .1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1960.1961.1966 à/to 1973 Tracy.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Cieorges.1958, 1964.1968, 1970 à/to 1973 incl.Sept-Ile-.1967.1968.1971 à/to 1973 incl.Laval.1969.1970.1972 et/and 1973 incl.Blainville.1971 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1956.1958, 1964.1970.1971 et/and 1973 Québec.1970 à;to 1973 incl.Montreal.1966 à.to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Shipton.1969 à/to 1973 incl.Longueuil.1967 et/and 1969 St-Jérome .1965.1968 à/to 1973 incl.North Hatley .1971 à/to 1973 incl.Yeni-e en Québec.1962 à/to 1973 incl.Longueuil 1969 â/to 1973 incl.Montreal .1963.1970 à/to 1973 incl.Laval.19CS, 1971 à/to !973 incl.l'ont Viau.1961.1966 à;to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal .1962 à/to 1965 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Saint-Félicien.1970 à/to 1973 incl.Québec 1971 à/to 1973 incl.Lava!.1970 à/to 1973 incl.LANDSCAPE SALES CO.LTD.SAM LANDSMAN INC.LANGCO INC.LANC.Y LTEE.LAURENTIAN SKI-DOO CENTRE INC.LAVE ALTO MODERNE INC.J.P.LAVERDIERE INC.O.V.LEGER INC.LEMAIRE AUTO INC.LIBRAIRIE EDI BEC INC.LIGl'E DE BALLE MOLLE ST-C.EORGES.LIGUE DE HOCKEY INTERMEDIAIRE \"A » DE L'EST DU QUEBEC INC.LIGUE DE HOCKEY LAVAL SENIOR INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE BLAINVILLE.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLE DE CHARLESBOURG LINGERIE LADO INC.LINMER INVESTMENTS LTD.LOCATEX INC.LODGE TRANSPORT LTD.LES LOISIRS DE FATIMA DE CITE DE JACQUES-CARTIER LOISIRS DU LAC MASSIE INC.LES LOISIRS DE NORTH HATLEY INC.LOISIRS DE VENISE EN QUEBEC INC.LONGUEUIL PLASTERING INC.THEODORE J LUBBERS CO.INC.LUNETTERIE LABERT LIMITEE M A M CONSTRUCTION INC.M & M INVESTMENTS INC.MAIN LUMBER CO.LIMITED MAISON ROMEO INC.MAISONEX LTEE.MAISONS ECONOMIQUES B.G.INC.MAISONNIUVE METALS & SMELTING INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 197-1.105' année.Il' 50 7359 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MANY GOODMAN REALTIES LTD.MANNY'S DELICATESSEN LTD.LE MANOIR STE-AGATHE INC.MAPLE GROVE ISLAND CORP.MAPLE LEAF TRUCK LINES INC.MARINE COMPUTER CENTER LTD.MAR-LAN INC.MARSPEG INC.MARTIN'S DRIVE IN RESTAURANT INC.MASKINONGE STOCK CAR INC.MAS8ICOTTE TRANSPORT INC.RODOLPHE MASSON INC.MASTER REALTIES INC.MASTER SYSTEMS LTD.MASTER TILERS CORPORATION.MASTER WOODCRAFT LTD.MATOL RESEARCH LIMITED MATTE & ST-ARNAUD AUTOMOBILES INC.McAM LTD.McDONALD-CARTIER LTD.McKAY TRANSPORT INC.M EI LAN INC.MICHAUD, GENDRON INC.MILAIR AVIATION INC.MINING COMPANY OF THE NORTH LTD.LE MIROIR DU QUEBEC INC.MIZENEK ELEVATOR COMPANY.MOBEL CONSTRUCTION LIMITEE.MOBILE MOTEL INC.MOBITAP LTEE.MODAL INC.MOLISE PAVING CO.LTD.MONACCO DEVELOPMENT CORP .MONIK REALTY CORP.Montreal.1960.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Agathe.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.CôteSt-Luc.1972,1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Bccancour.1967 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Coteau Landing .Montreal.Maskinongé.Montreal.1973 196S à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St.Vincent-de-Paul.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.Québec.1957, 1958, 1963 à/to 1968, 1971 a/to 1973 incl.Montréal .1969 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1970 à/to 1973 inci.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Cookshire.196S.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Scpt-Iles .1972, 1973 West mount.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Laval.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Mercier.Montreal.Montreal.1967, 1968.1971, 1973 1969 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1963, 1967 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.Xo.50 Nom de la compagnie iVomc of the company MONOH SPORTWEAR LTD.MONT ROUGEAU LAND HOLDINGS INC.MONT TREMBLANT ESTATES INC.MONTREAL J.M.ELECTRIC INC.MONTREAL SWITCHGEAR INC.MOTEL LE BOCAGE SIGHTSEEING INC.MOTEL MAURICIEN LTEE .MOTEL DE L'ORMAIE INC.MOUVEMENT LAÏQUE DE LANGUE FRANÇAISE.MULTICOLOR CIMENT LTEE.MULTIPLAN INC.MUSEE DE LANAUDIERE.NETTOYEUR MAGIQUE DE L'OUTAOUAIS INC.LE NETTOYEUR « MAISON BLANCHE» INC.NIAGARA MAINTENANCE INC.C.B.NIELSEN & CO.LTD.J.NIELSEN LIMITED.BRUCE G.NORMAN LIMITED.O.T.J.DE WATERYILLE INC.L'OEIL 1969 INC.OLEGA LIMITEE.OPERA CONSTRUCTION INC.OTTAWA SILICA COMPANY LTD, (NO PERSONAL LIABILITY) OUELLETTE & LA FOREST INC.P.J.B.& ASSOCIATES INVESTMENT CORP.P.N.L.CONSTRUCTION INC.P.V.C.ISOLATION INC.PAGE & PAGE AMEUBLEMENTS INC.PALMA DEVELOPMENT CORPORATION.PALMER JUNIOR WEAR MFG.CO.INC.PAMORE INVESTMENT CORPORATION.PAN-AM EQUIPMENT AND MACHINERY LTD.PAN AME BISTRO INC .PARACHUTE ST-JEAN INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1971 à/to 1973 incl.Westmount.1969 à/to 1973 incl.Mount Royal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1970 à/to 1973 incl.St-Lambert.1960, 1963 à/to 1973 incl.Canton Mailhot.1971 à/to 1973 incl.St-Francois-Xavier 1971 à/to 1973 incl.de Batiscan Montréal.1964, 1970à.to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl, St-Charles-Borromée.1967 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1971 à/to 1973 incl.Anjou.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à'to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Westmount.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Waterville.1966 à/to 1973 incl.Driirnmondville 1969 à/to 1973 incl.Hull.1961.1962, 1971 à/to 1973 incl.Duvernay.1963, 1965.1968 à, to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Lafléche.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1968, 1972, 1973 Montréal.1958, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1964 incl.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-Jean.1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année.n° 50 7361 Nom de la compagnie Xante of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed GUY PARADIS AUTO BODY INC.PIERRE PARANT AUTOMOBILE LTEE.PAR-BIZ INC.LE PARC SAINT JOVITE INC.PARK CONSTRUCTION LTD.PARK LANE GIFTS LTD.PARK PLAZA GARDENS CORP.PARK PRODUCTIONS LTD.PARKLAF INC.PARKYTLLE CONSTRUCTION INC.PARTHIMOS ELECTRIC LAMPSHADES CO.LTD.PASTEUR ST-URBAIN REALTY CORP.PAT REALTIES LTD.PATISSERIE ROSEMONT LTEE.PATRY-JOANIS LTEE.PEINTURES LABELLE INC.J.L.PELLERIN INC.LA PERLE DU LAC INC.PETROLE GAZET INC.PHEASANT LAND INC.PHILERIC ENTERPRISES LTD.PINO LANDSCAPING CO.LTD.PISCINE CITADELLE INC.THE PLACE D'ARMES-ST.JAMES STREET VICTORIA SQUARE BUSINESSMEN'S ASSOCIATION LES PLACEMENTS D.L.R.INC.LES PLACEMENTS BACDEM INC.LES PLACEMENTS BELIVEAU INC.PLACEMENTS GRATIEN GELINAS INC.PLACEMENTS KAROL INC.PLACEMENTS LAJEUNESSE LTEE.LES PLACEMENTS LAMARRE LTEE.LES PLACEMENTS MICHEL DROLET INC.PLACEMENTS DE LA MONTAGNE INC.Montreal.1971 à/to 1973 incl.St-Antoine-des-Laurenti- 1959 à/to 1963 incl.des 1965 à/to 1973 incl.Quebec.1969 à/to 1973 incl.St-Jovite.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1965 incl.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Maniwaki.1969 à/to 1973 incl.St-Eustache.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1964 à/to 1973 incl.Ste-Adèle-en bas.1964 à/to 1973 incl.St-Léonnrd.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.V.St-Laurent.1972,1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Québec.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1964, 1966, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1968 à/to 1973 incl.Québec .1961, 1963 à/to 1973 incl. 7362 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1073.Vol.105.Xo.50 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Télesphore.1971 à/to 1973 incl.Noranda.1961 à/to 1973 incl.Templeton.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Ste-Madeleine.1967 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1972 et/and 1973.Outremont .1969 à/to 1973 incl.Saint-Lambert.1968.1970 à/to 1973 incl.Ste-Angèle.1973 Québec.1966.1968.1969, 1972 et/and 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.La Tuque.1971 et/and 1973 St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.St-Félicien.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.196S à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1965 à/to 1973 incl.Rawdon.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Kepentigny.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Lachine.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1968 à/to 1973 incl.St-Lambert.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1966,1968,1969,1973 Jacques-Cartier.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Boucherville.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.LES PLACEMENTS NUCKLE INC.LES PLACEMENTS RAGILLES DE QUEBEC LTEE LES PLANTATIONS EDEN INC.PLOMBERIE BLAIS PLUMBING INC.PLOMBERIE PAPINEAU LTEE.PLOMBERIE PARIS INC.PLOMBERIE STE-MADELEINE LTEE.POLIGRAPHIC LABEL & TAC.(QUEBEC) INC.PORT O MATIQUE LTEE.LES PRODUITS D'ARGILE DE ST-LAMBERT LTEE PRODUITS CHIMIQUES COBEL LTEE.LES PRODUITS LAURENTENS J.G.B.INC.PROFESSIONAL AUTOMOBILE SALESMEN'S ASSOCIATION LES PROMOTIONS ALBANY INC.LES PROMOTIONS SUCCES INC.PROPANE NORD INC.LES PROVISIONS MODERNES (MONTREAL) INC.LES PUBLICATIONS JIRAC LTEE.PUBLICATIONS LABELLE INC.LES PUBLICATIONS LAMON INC.PUBLICITE JEN DRO INC.PUBLICONTACT INC.QUEBEC AUTOMOTIVE INDUSTRIES LIMITED.THE QUEBEC CITY SUMMER STOCK THEATRE CORPORATION QUEBEC DHAGWAY INC.QUEBEC ELEC INC.QUEBEC STORE INC.QUICK O WASH INC.RAILROAD M EN'S BENEVOLENT FUND RAMSAY PLATE GLASS CO.LTD.RANCH J.N.INC.RAPID GRO CONSTRUCTION CO.LTD.RE HEC INC.REALTY GROUP INCORPORATED.RECUPERATION MONDA INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105' année.»° 50 7363 Nom de la compagnie Name of Ike company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed REMEMBRANCE INVESTMENT CORP.LES REPRODUCTIONS ARTISANALES NOUVELLE FRANCE INC.LE RESTAURANT BARONET INC.RESTAURANT ETOILE FILANTE INC.RESTAURANT LE GRAND PRIX INC.RESTAURANT LE POULET & MOI INC.RESTAURANT LES 4 SOEURS LTEE.J.J.RINGUET INC.RIVARD AUTO BODY INC.RIVER REALTY & INVESTMENT CO.LTD.ROCKLAND ESTATES INC.RONALD HOME PARTIES LTD.ROSS & HARRIS LIMITED.ROULOTTES DUBOIS INC.G.ROUX LIMITEE.ROVEL INC.S.H.C.HOLDING CORPORATION.S.I.V.A.LTEE.S & J ASSOCIATES INCORPORATED.J.B.ST-JACQUES LIMITEE.ST-JEROME AUTO SPORT INC.ST-JOSEPH JOBBING LTD.ST-LAMBERT TUILES & TERRAZZO LTEE.ST-ZOTIQUE RESTAURANT INC.STE-ROSALIE VENDING INC.LE SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO-NEIGE INC.SALON NATIONAL GRAND PRIX LTEE.PAUL-E.SAUVE INC.J.SAVOY & CIE LTEE.SCULPT-O-MATIC INC.SECRET DE LORETTE INC.JEAN SEGUINEL INC.LES SEMAINES INTERNATIONALES DU CINEMA.LES 7 JOURS DU CINEMA DE HULL.Lachine.1967 à/to 1969 incl., 1973 Sillery.1972 et/and 1973 St-Romuald.1968, 1969, 1972 et/and 1973 St-Jean.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Saint-Sauveur.1968 à/to 1973 incl.Plessisville.1972 et/and 1973 Rimouski.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1964, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.St-Bruno.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.St-Antoine-des-Lauren- 1966 à/to 1973 incl.tides Trois-Rivières.1961, 1968 à/to 1973 incl.Greenfield Park.1959, 1964 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Ste-Rosalie.1966 à/to 1970 incl,, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Dorion.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Longueuil.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Mont-Tremblant.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Hull.1968 à/to 1973 incl. 7364 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, December 15.1973, Vol.105.So.50 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Ste-Cécile-de-Milton.1969 à/to 1973 incl.Dolbeau.1970 à/to 1973 incl.Jonquière.1970, 1972, 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.l'ierrefonds.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1963 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Gatineau.1965 à/to 1973 incl.St-Michel.1963 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1965, 1967 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1970 à/to 1973 incl.Waterloo 1972, 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl, Montréal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Marieville.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.C'ap-de-la-Madeleine .1972, 1973 Montréal.1972, 1973 Québec.1972.1973 Montreal.1972.1973 Montreal.1967 â;to 1973 incl.Montréal.1968, 1969, 1972, 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Drummondville.1970 à/to 1973 incl.Québec.1972, 1973 Québec.1972, 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Didace.1964 à/to 1973 incl.Westmount.1961 à/to 1963 incl.1970 à/to 1973 incl.LE SERVICE DES BOULANGERIES I.ABBE & ARMSTRONG INC.SERVICE DE SCIERIE DOLBEAU LTEE.SERVICE SUPER SPORTS LTEE.SERVICES ADMINISTRATIFS LAURIN-LORANGER INC.SERVICES KAN-KAF INC.SHERWOOD DEVELOPMENT CORP.SHIRLEY'S DOWNTOWN RESTAURANT INC.SILVER LAND HOLDINGS LTD.SOCIETE D'ASTRONOMIE DE LA MAURICIE.SOCIETE BOG EST INC.LA SOCIETE DE CHASSE ET PECHE LAURENTIEN DE GATINEAU SOCIETE DE CONSTRUCTION RM.INC.LA SOCIETE JEAN TALON INC.SOCIETE JENNIS INC.LA SOCIETE DE LA JEUNESSE DE STE-URSULE.SOCIETE DES LOISIRS ET ECOLOGIE DE WATERLOO INC.LA SOCIETE PAPINEAU INC.LA SOCIETE DE PLACEMENTS ST-GEORGES LTEE____ LA SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE, SAINTE-MARIE.SOLISE INC.SOMARO INC.SONIC INC.SOPAR CONSTRICTION INC.SOUTHERN INDUSTRIAL BUSINESS SALES LTD.SOUVENIR LAND DEVELOPMENT CO.LTD.SOVICO INC.SPIC INCORPOREE.SPORBEC INC.LE SPORT CLUB DE QUEBEC INC.SPORTS INTERNATIONAUX DE QUEBEC.STAR OFFICE SUPPLIES INC.STARLET MANUFACTURING CO.LTD.STATION ESTIVALE MASKINONGE LTEE.STATLER-KERN LTD. GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' aimée, h\" 50 7365 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Addreu Rapports non produits Returns not filed STEERING LTD.STEVNEV ENTERPRISES LTD.STRATHDEE'S FLOWER SHOP INC.STUDIO J.P.M.INC.STUDIOLITH INC.SUBSTANTIAL DEVELOPMENTS OF MONTREAL LTD.J.W.SULLIVAN INC.GEORGE SULLY (1958) INC.SUMAC LAND CORPORATION.SUMAR CONSTRUCTION LTD.SWANTON INVESTMENT CORP.SYDLI INC.SYSTEL INC.SYSTEMES DE BUREAUX ST-LAURENT LTEE TAVERNE CHEZ JOS INC.TAVERNE PINET INC.TERREBONNE PARK ESTATES LTD.GERARD TETRAULT LTEE.GEORGES THEBERGE INC.THRU-WAY PARKING LTD.TIP TOP LEATHER GOODS MFG.LTD.TOMEO & COLAVECCHIO INC.TOWNSHIPS TRANSPORT LTD.TRANS ST-LAURENT EQUIPEMENT INC.TRANSPORT E.L.LTEE.TRANSPORT GEORGES LACAILLE LTEE.TREMBLAY' & LAGARDE INC.TRICOTAGE G 4 B LIMITEE.LES TROUPIERS DE JONQUIERE INC.TRU-ACRES INC.GEORGES TRUDEAU INC.JOHN TRUDEL INC.LES TUYAUX DE BETON MAURICIENS INC.20TH CENTURY\" LADIES WEAR INC.L'UNION DE PARENTS DU GRAND SHAWINIGAN Montreal.Montreal.Beaconsfield.Montréal.Outremont.Montreal.Québec.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Beloeil.Montréal.St-Laurent.T rois-Rivières.Québec.Montreal.Montréal.St-Vallier.Montreal.Mont-Royal.Montreal.Sutton.Ste-Foy Montréal.St-Jean-Baptiste .Montréal.Montréal.Jonquière.Montréal.St-Hilaire-de-Rouville.Montréal.St-Sévérin-do- Proux vi I le, Montreal.Sliawinigan.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.1961, 1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.1958, 1971 à/to 1973 incl.1966, 1968 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1972, 1973 1972, 1973 1971 à/to 1973 incl.1972, 1973 1966, 1970 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1971, 1973 1965 à/to 1969 incl.1972, 1973 1964.1967 à/to 1973 incl.1972, 1973 1968, 1970 à/to 1973 incl.1968, 1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1972, 1973 1968 à/to 1973 incl.1965, 1969 à/to 1973 incl.1964, 1971 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl. 7366 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed 25 RUE ST-LOUIS INC.UNITECH INC.UNITED BINDING INC.UNIVERSITY INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION LTD.USINAGE ET SOUDURE BAIE COMEAU INC.V.L.AUTO BODY INC.VAL MORIN ENTERPRISES LTD.VALCOURT & FILS AUTO PARTS INC.J.P.VEILLEUX INC.LES VICS DE GRANBY INCORPOREE.VIDEX INC.J & S VINCENT INC.J.LOUIS VOGHEL LTEE.LES VOYAGES SOLMAR INC.WATER MATIC MONTREAL LTD.THE WATERLOO BASKETBALL CLUB.G.S.WATT & ASSOCIATES LTD.WEST END HEALTH STUDIOS INC.WEST END TAVERN INC.YOUNG-1 INC.ZIMCOLOR COMPANY.Québec.1968.1972 St-Laurent.1973 Montreal.1962.1970 a/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Baie-Comeau.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1962.1970 à/to 1973 incl.St-Dominique.1964 à/to 1973 incl.St-Georges.1971 à/to 1973 incl.Granby.1964 à/to 1973 incl.Laval.1968 à/to 1973 incl.Laval.1971 à/to 1973 incl.Beloeil.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Verdun.1967 à/to 1973 incl.Waterloo.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl.Lachine.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1970 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1971 à/to 1973 incl.Lachine.1965 à/to 1969 incl.1973 Le directeur du service des compagnies, 55080-o Pierre Desjardins.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.550s0-o Pierre Desjardinb, Director of the Companies Serrice.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date A.G.IMPORT & MFC.CO.LTD.AGENCE D'ASSURANCES IDEAL INC.LES AGENCES INTERTROPICALES INC.LES AGENCES POINTE-AUX-TREMBLES ALASKA OIL INC.ALJA INC.Montreal.06 12 1971 Montreal.27 «3 1963 Québec.28 01 1971 Pointe-aux-Trcmbles.19 06 1967 St-Léonard.07 08 1971 St-André Avelin.30 12 1965 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année.n° 50 7367 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company\tAddress\t\tDate\t \t\t05\t08\t1966 \t\t07\t10\t1968 AMERICAN FILM DISTRIBUTING COMPANY LIMITED.\tMontreal.\t05\t10\t1971 \t\t24\t01\t1969 \t\t28\t08\t1968 \t\t09\t12\t1971 \tHull .\t28\t08\t1957 \\SSOCIATION DU CLUB DE GOLF LORRAINE INC.\tLorraine.\t06\t05\t1966 L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE STE-M A RI E-SUR-LE-LAC\tSte-Marie-sur-le-Lac.\t15\t11\t1963 L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE ST-VTN-CENT-DE-PAUL INC.\tSt-Vincent-de-Paul.\t10\t09\t1962 L'ASSOCIATION DES DENTISTES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.\tMontréal.\t30\t03\t1883 L'ASSOCIATION DES INSPECTEURS SANTE PUBLIQUE PROVINCE QUEBEC\t\t11\t06\t1966 L'ASSOCIATION DES LOISIRS DE COTE TERREBONNE INC.\tSt-Louis-de-Terrebonne.\t15\t09\t1971 \t\t07\t08\t1967 ASSOCIATION MONTREALAISE DE JELSI\t\tIS\t04\t1969 L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET DES LOCATAIRES DU LAC CORBEAU\t\t14\t11\t1967 L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE ST-JOSEPH INCORPOREE\tHull.\t01\t04\t1963 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DE ST-JEAN DTBERVILLE INC\tSt-Jean D'Iberville.\t18\t12\t1945 ASSOCIATION DES RELATIONNISTES DU QUEBEC\t\t13\t12\t1971 ASSOCIATION SOCIALE U.A.P.SAGUENAY LAC ST-JEAN INC.\tChicoutimi.\t09\t12\t1966 L'ASSOCIATION TOURISTIQUE ET SPORTIVE DE JONQUIERE NORD INC.\tJonquière.\t15\t08\t1969 ATELIER JAC INC.\t\t10\t03\t1970 ATELIERS PIERRETTE & DENIS LTEE .\t\t22\t11\t1971 \tMont St-Hilaire.\t10\t09\t1971 AU LAMPADAIRE INC.\t\t30\t12\t1963 AUBERGE DE JEUNESSE VIVE LA VIE.\t\t30\t07\t1963 AUTOS BRETAGNE INC .\tHauterive.\t29\t07\t1963 \tChicoutimi.\t29\t03\t1972 BASKATONG MINING CORPORATION.\tMontreal.\t10\t03\t1961 BEJADO INC.\t\t28\t02\t1968 BELL PROVISIONS INC.\tMontreal.\t15\t03\t1967 J.BERDOV & CIE INC.\t\t16\tHI\t1967 BES CONSTRUCTION INC.\t\t26\t05\t1972 \tMontréal.\t23\t06\t1969 736S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Nom de la compagnie Name of the company BOUTIQUE ROMEO ET JULIETTE INC.LORENZO BUREAU INC.LES CAMIONNEURS INDEPENDANTS DE LOTBINIERE INC.CAMPING LAC McGREGOR INC.CANADIAN ASSOCIATION OF YOUNG MEN OF ISTAMBUL.CAN-ITAL INVESTMENTS LTD.CENTRALE DE LOGEMENTS J.M.J.INC.CENTRE DE DECORATION LA TUQUE INC.CENTRE D'ETUDES POLITIQUES DE QUEBEC ET DE LA REGION INC.CENTRE DE JEU DE PAUME DU QUEBEC INC.CENTRE RECREATIF DU LAC LYSTER INC.JEAN R.CLERMONT INC.LE CLUB DES ANGES INC.CLUB D'AUTO-NEIGE VAL MORIN INC.CLUB DE CHASSE ET PECHE DU LAC EAST BRANCH POND INC.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE MAGPIE INC.CLUB COPAINS-COPAINS METROPOLITAINS.CLUB DE CROQUET QUEBEC INC.CLUB HERMINE INC.CLUB DE HOCKEY PEE WEE INTERNATIONAL DE STE FOY'.CLUB DU LAC RUDOLPHE INC.CLUB DE MOTO NEIGE LES AIGLES DE STE-ANNE DES MONTS INC.CLUB DE LA RIVIERE CORNEILLE INC.CLUB DES SENTIERS (NORD DE JOLIETTE) INC.CLUB SOCIAL MERCURE INC.CLUB SPORTIF COMPTON INC.COMITE DES LOISIRS SAINT NOM DE JESUS LTEE.COMITE QUEBECOIS D'AIDE ET DE DEVELOPPEMENT (TIERS-MONDE) COMMERCIAL CONSUMERS' MARKETING CORP.COMMISSION DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITE DE ST-CALIXTE INC.LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SODEC.COMPAGNIE D'EQUIPEMENT ET REFRIGERATION FRONTENAC INC.LA COMPAGNIE FRANCO-CANADIENNE D'ALIMENTATION INCORPOREE LA COMPAGNIE KIRBY DE MONTREAL INC.Adresse Incorporation Address Date Montréal.19 07 1968 St-Victor.26 05 1969 St-Gilles.27 06 1966 Templeton.17 03 1972 Montreal.16 06 1966 Montreal.23 08 1966 Montréal.31 12 1963 La Tuque.03 12 1971 Québec.17 05 1971 St-Léonard.13 11 1969 Barnston.28 08 1968 Montréal.04 08 1966 L'Ange-Gardien.02 05 1968 Val Morin.31 12 1971 Sherbrooke.04 09 1968 Sept Iles.03 09 1971 Montréal.01 10 1970 Ste-Thérèse.06 05 1968 St-Eustache.25 11 1968 Ste-Roy.01 05 1964 St-Louis-de-Terrebonne 19 08 1968 Ste-Annc-des Monts.29 12 1971 Victoriaville.18 05 1961 St-Ambroise-de- 13 11 1969 Kildare Jonquière.15 09 1971 Compton.07 01 1971 Rivière du Moulin.05 01 1961 Quebec.09 06 1971 Montreal.06 03 1968 St-Calixte.15 02 196s Montréal.31 og ]lm Montréal.07 06 1960 Québec.10 07 1964 Montréal.29 04 1971 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7369 Nom de la compagnie Name of the company LA COMPAGNIE DE PUBLICATION DU JOURNAL L'ECHO DU DIMANCHE INC.CONCRETE REPAIRS & WATERPROOFING CO.LTD.CONSEIL DE L'AGE D'OR DU SECTEUR LAPOINTE.CONSEIL D'HABITATION ECONOMIQUE BEAUPORT LTEE.LE CONSEIL ST-HENRI.CONSIDINE SALES LIMITED.CONSOLIDATED INDUSTRIAL VENTURES LTD.CONSOLIDATED MAPLE PRODUCTS LTD.CONSOLIDATED MORTGAGE SWISS INTERNATIONAL OF QUEBEC INC.CONSTRO DESIGN INC.CONSTRUCTIONS JOCELIN LTEE.CONSUMERS DISCOUNT CLUB INC.CONTEMPORA INC.CONTINENTAL MINERALS AND RESOURCES LTD.CONTREPLAQUES TROIS PLIS INC.COOKSHIRE METAL WORKS LTD.COPIA INVESTMENT CORP.COPPERNIC MINES LTD.CORDINA INC.CORONET VOYAGES INC.CORPORATION DE DEVELOPPEMENT JEUNESSE.CORPORATION DICOM.COSY HOUSING INC.J.LEONARD COTE & FILS INC.COTE.LIZOTTE, EMOND INC.MARCEL COTE MUSIQUE INC.COTE-NOIRE DEVELOPMENT INC.COTE-NORD PARA CLUB INC.COULONGE LUMBER CO.LTD.CREQUETTE ENTERPRISES INC.D.G.S.INC.D.L.F.INVESTMENTS LTD.DANUBE TRADING (QUEBEC) LTD.DARRICK MINES LTD.P.DAVID CONSTRUCTION INC.DEL-FRAN SERVICE INC.Adresse Address Incorporation Date St-Jérôme.18 04 1969 Giffard .01 08 1949 Kcnogami.10 04 1972 Ste-Catherine 30 08 1970 d'Alexandrie Montréal.14 09 1967 Montreal.11 02 1965 Montreal.11 01 1967 Cowansville.30 03 1954 Montreal.02 07 1971 Hudson.13 10 1971 Rivicre-du-Moulin.25 10 1971 Montreal.05 08 1968 Montreal.01 03 1971 Montreal.15 10 1971 Montréal.22 03 1965 Cookshire.07 02 1969 Montreal.02 12 1958 Rouyn.26 01 1962 Montreal.19 08 1965 Montréal.10 03 1967 Rimouski.09 07 1971 Montreal.14 12 1971 Montreal.08 01 1959 Magog.01 06 1970 St-Hyacinthe.23 04 1964 Québec.10 03 1969 Montreal.01 08 1967 Sept lies.09 05 1968 Fort Coulonge.14 04 1965 Montreal.01 10 1971 Charny.16 11 1966 Montreal.01 02 1972 Laval.04 11 1966 Montreal.13 08 1971 Ste-Marguerite.05 02 1959 Québec.02 08 1971 7370 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.No.50 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date J.P.E.DELISLE INC.ROGER DESJARDINS INC.CHARLES DESMARTEAU.COURTIER EN IMMEUBLES INC.LE DIALOGUE (DU QUEBEC) INC.DIDACTA INC.DIFFUSIONS INTERNATIONALES DU LIVRE INC.DIMAC INC.DIMENSION SHERBROOKE.DIMENSIONS UYA INCORPORATED DIMPEX CORPORATION.DOLEMER INC.J.J.DUBOIS LIMITEE.DUVER CREEK GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) DWAYNE FASHIONS INC.EASY-TOW TRAILERS COMPANY.ECOLE DES LANGUES DE MONTREAL INC.LES ECURIES ST-JOVITE INC.EDITION DIFFUSION ISERMAN INC.ELBA INC.LES ENTREPRISES ASSINIWI LTEE.LES ENTREPRISES DAUVILLE INC.LES ENTREPRISES G.& F.DESMARAIS ET FRERE LIMITEE.LES ENTREPRISES DU GRENIER LIMITEE.LES ENTREPRISES INTERURBAINES INC.LES ENTREPRISES JAD INC.LES ENTREPRISES JALMARK INC.LES ENTREPRISES LAGATE INC.LES ENTREPRISES LUCIEN TREMBLAY INC.ENTREPRISES MEICO INC.ERB-COR LTD.EUROCAN DEVELOPMENTS LTD.F.T.FOOD CONSULTANT INC.FASHION CONVERTERS LTD.KASHIONKNIT IMPORTS (QUEBEC) LTD.FAVOURITE GENERAL CONTRACTORS CO.LTD.FEDERATION DE LA JEUNESSE SPORTIVE D'IBERYTLLE INC.LA FEDERATION DE JUDO ET DES ARTS MARTIAUX INC.Québec.Notre-Dame-du-Sarré-Coeur Boucherville Laflcche .Montreal.Laval.Montreal .Sherbrooke.Dollard-des-Ormeaux Montreal.Québec.Riviére-à-1'ierre.Montreal.Montreal.Laval.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Deauville.St-Hyacinthe.Québec.Montréal.St-Gilles.St-Hyppolyte.Hull.Clermont.St-Lambert.Montreal.Montreal.Hull.Montreal.Montreal.Montreal.Iberville.Montréal.14\t04\t1971 12\t11\t1965 06\t04\t1970 30\t11\t1907 21\t06\t1968 07\t03\t1969 OS\t01\t1968 20\t11\t1969 22\t05\t1963 23\tin\t1968 11\t11\t1971 30\t01\t1961 08\ton\t1936 06\t03\t1972 \"Ô\tCi7\t1967 07\tOS\t1965 21\t02\t1969 02\t04\t1969 20\t05\t1966 29\tI\"\t1968 25\t10\t1971 18\t\"S\t1971 31\t10\t1963 11\t03\t1963 21\t01\t1965 23\t03\t1970 06\t04\t1971 21\t12\t1971 22\t01\t1970 15\t01\t1969 01\t12\t1971 09\t07\t1971 24\t12\t1968 in\t04\t1972 01\t04\t1964 31\t05\t1967 27\t08\t1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année.n° 50 7371 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company\tAddress\t\tDate\t LA FEDERATION DE KARATE DU QUEBEC.\tMontréal.\t15\t05\t1967 FEDERATION NATIONALE DES AUBERGES DE JEUNESSE DU\t\t12\t02\t1970 QUEBEC INC.\t\t\t\t LA FEDERATION PROVINCIALE DES COMMERÇANTS DETAIL-\tMontréal.\t28\t06\t1971 LANTS\t\t\t\t FEDERATION QUEBECOISE DE KARATE INC.\tMontréal.\t31\t08\t1971 \t\t26\t] 1\t196S LA FERME MARAICHERE COTE-NORD INC.\t\t03\t06\t1969 \t\t07\t10\t1971 \tJoliette.\t22\t10\t1965 \t\t28\t11\t1972 FOYER DE L'ILE D'ORLEANS INC.\t\t11\t11\t1969 \t\t15\t03\t1968 G.D.SALES CO LTD.\t\t24\t01\t1966 \tSte-Emilie-de-l'Energie\t16\t12\t1971 \tMontréal.\t03\t07\t1963 \t\t09\t03\t1965 \t\t24\t08\t1965 GESTION PROVENCE INC.\t\t21\t10\t1971 \t\t02\t11\t1971 LE GITE OUVRIER INC.\t\t1S\t06\t1964 \tSherbrooke.\t21\t03\t1972 \t\t08\t07\t1971 \t\t03\t02\t1969 \t\t08\t10\t1968 HAMEL ET LAHAYE CONSTRUCTION INC.\tIberville.\t03\t11\t1971 HOLIDAY MAGIC DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF MONTREAL.\t\t24\t11\t1967 \tMontréal.\t29\t03\t1950 \t\t23\t10\t1967 \tMontreal.\t03\t11\t1971 \t\t16\t12\t1971 \t\t01\t09\t1971 \t\t03\t10\t1968 \tBeauharnois.\t02\t12\t1971 \tQuébec.\t31\t01\t1972 \tSt-Gabriel-de-Brandon.\t17\tos\t1968 \tSte-Julienne-de-Rawdon.\t28\t12\t1966 \t\t04\t04\t1970 7372 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 10.1973, Vol.105.No.50 Nom de la compagnie jVamr of the company Adresse Address Incorporation Date INBEC INC.INDEPENDANT VETERANS ASSOCIATION.INDUSTRIAL MOTOR & TRANSMISSION SPECIALTIES INC INFOR-VISION QUEBEC LTEE.INSERVA (CANADA) LTEE.LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU QUEBEC INC.L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE DU QUEBEC INC INSTITUT DE PROGRAMMATION J.L.L.INC.THE INTERCHANGE HOSPITALITY CLUB INC.INTERCOASTAL PROPERTIES LTD.INTER-SERVICE CLUBS COUNCIL.INTREVIC INC.IPREP INC.IRISH HOUSE CORPORATION.ITER SERVICE INC.J.L.MARINE EQUIPMENT INC.J.M.TRANSPORT LTEE.J.P.AUTO LTEE.J.P.CONSTRUCTION INC.J & R HOLDINGS CO.LTD.J.T.ISOLATION INC.J.& W.INVESTMENTS INC.JABIN INC.JACKEN INC.JACQUES AUTOMOBILES INC.JACQUES MARC DEVELOPMENT INC.JAMES STERLING PAPER FASHIONS (CANADA) LTD.JANIN-TRUDEAU COMPAGNIE LTEE.JASNA CONSTRUCTION INC.JEAN PIERRE AUTO INC.JEL CORP.JEMO RENOVATION INC.JENKINS TETREAULT CONSTRUCTION INC.JERICHO TRADING CO.LTD.JETIC INC.JEUNEQ INC.JOANNE MODES INC.Montreal.Montreal.Montreal .Québec.Montreal.St-Lambert Dorion.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal .Montreal.Montreal.Montreal.Trois-Rivières.Montréal-Nord.Montréal.Ste-Rose-du-Dégelé .Cap-de-la-Madeleine.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal .Montréal.Montreal.Montreal.Montréal.Montréal.Mont-Laurier.,.Lachine.Québec.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal 05\t05\t1967 30\t06\t1967 08\t04\t1968 15\t10\t1971 15\t03\t1968 25\t03\t1966 12\t09\t1967 01\t02\t1971 10\t01\t1968 10\t09\t1969 27\t04\t1967 26\tm\t1966 23\t08\t1965 08\t08\t1968 31\t01\t1964 08\t07\t1968 24\t10\t1969 04\t08\t1965 13\tin\t1964 16\t02\t1965 30\t05\t1967 05\t02\t1968 29\t07\t1969 05\t09\t1961 27\t11\t1964 28\t11\t1969 14\t04\t1967 26\t05\t1964 12\t07\t1960 15\t06\t1971 26\t11\t1963 22\t11\t1971 11\t03\t1968 21)\t04\t1967 21\t03\t1969 27\t06\t1969 18\t12\t1958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année, n° 50 7373 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Incorporation Date JOBO INVESTMENT CORPORATION.JOËLLE LTEE.JOLEMA PUBLISHING LTD.LE JOLYMONT INC.JONES BUILDING LTD.M.JOSEPH & CO.JOUETS PROVINCIAUX INC.LE JOURNAL DE ST-LEONARD.LE JOURNAL DE SHERBROOKE INC.LES JOURNAUX UNIS DU QUEBEC INC JOYELLE INC.LES JOYEUX PROMENEURS INC.JULES RENOVATION INC.JULIAN INVESTMENT CORPORATION.JUNO INVESTMENTS INCORPORATED.G.JUTRASINC.JUTRAS & JUTRAS INC.KAMICO LTEE.KANGAROO SPEED SHOP INC.KARGO EXPRESS LTEE.KAXLE REALTIES INC.KENT TRADING INC.WAYNE P.KING & ASS.INC.KOBAN COSMETICS LTD.LABERGE (NORMAND) INC.LABORATOIRE MEDICAL METROPOLITAIN LABORATOIRES COSMEL'L INC.LABRANCHE & FILS INC.LA LAITERIE SAGUENAY LAC ST JEAN.LES LAITERIES PEE-WEE INC.LAKE COPPER LTD.LAM TRONIQUE LTEE.LA-MAI VALLEE INC.LAMARRE CONSTRUCTION INC.LAMIGO INC.LAMOTIIE AUTOMOBILE (1964) LTEE.LANARINC.Montreal.03 01 1969 Montréal.30 04 1964 Montreal.12 10 1971 Ascot.28 06 1971 Chandler.13 10 1964 Montreal.14 12 1961 Laval.09 11 1971 St-Léonard.07 12 1966 Sherbrooke.20 03 1964 Québec.27 07 1967 Montréal.31 07 1969 Beau port.23 03 1966 Pierrefonds.31 03 1969 Montreal.22 02 1968 Montreal.04 12 1958 Sillery.06 05 1968 St-Basile-le-Grand.17 02 1967 Québec.26 10 1971 Montreal.25 05 1971 Québec.24 04 1961 Montreal.31 01 1961 Montreal.11 03 1958 Montreal.11 12 1967 Outremont.24 04 1968 Sept-Ues.06 11 1969 Montréal.21 07 1961 Montréal.23 10 1969 Bolton.16 04 1968 St-Jérôme.26 06 1964 Beloeil.15 10 1968 Montreal.04 04 1968 Laval.11 08 1971 Rawdon.08 04 1965 Jonquière.14 08 1958 Ste-Foy.10 04 1967 Montréal.15 01 1962 Victoriaville.23 01 1968 7374 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15.1973.Vol.105.No.50 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse A ddresa Incorporation Date J.RAYMOND LANGLAIS HOLDING INC.LANORACINC.LAURENTIAN SALES CO.LTD.JACQUES LEFEBVRE INC.G & R LESSARD INC.J.L.LESSARD CONSTRUCTION LTEE.LIBRAIRIE HEROUX LTEE.LIGUE DES CONTRIBUABLES DE LACHUTE.LYONEL LITWACK CONVERTERS INC.J.R.LLOYD MONTREAL.M.G.M.INC.MX.INTERIOR MAINTENANCE INC.MACHINERIE LOURDE ANDRE DORE INC.IAIN D.MACKIE & CO LTD.MAG-MONT LTD.MARKS & MARTIN INC.MAROIS ET SEGUIN INC.MARTIN STEEL (1966) LTD.MARY ANN SERVICES LTD.MC DONALD HERON CORPORATION.MECO ELECTRIC (1960) INC.MECO ELECTRIC (QUE) INC.MESOTEK INC.LA METALLURGIE DE LISLET LTEE.METRO OFFSET INC.MEUBLES DIANA INC.MEXICANA MINING CORPORATION.MIRACLE PAINTING AND CONTRACTING INC.MOM.RESTAURANT LTD.MO-MER ELECTRIQUE INC.MONT ALPINO INC.MONTCALM MINES LTD.MONT-MILL INC.THE MONTREAL ALUMNI CLUB OF TAU KAPPA EPSILON FRATERNITY INC.MONTREAL JET PORT INVESTMENT LTD .MONTREAL SETTLEMENT IN ISRAEL INC.MONUMENT CONSTRUCTION CO.LTD.Beaconsfield.23 11 1971 Laval-sur-le-Lac.24 04 1964 Montreal.17 05 1968 Buckingham.23 05 1967 Montreal.27 01 1972 Tracy.28 10 1963 Laval.04 11 1968 Lachute.05 10 1964 Montreal.02 07 1968 Montreal.14 11 1966 Montreal.08 06 1966 St-Lambert.01 05 1967 Cap Santé.25 06 1965 Montreal.23 10 1967 Montreal.13 12 1971 Montreal.11 05 1967 Hull.09 12 1971 Montreal.27 06 1966 Montreal.23 03 1973 Montreal.05 11 1971 Montreal.06 06 1960 Montreal.15 06 1960 Montreal.12 01 1971 L'Isletville.13 07 1964 Montreal.19 10 1971 Montréal.02 05 1967 Montreal.29 01 1971 La Salle.09 07 1969 Montreal.28 11 1960 Québec.12 09 1969 Montréal.27 05 1971 Montreal.09 08 1971 Beauport.25 10 1971 Montreal.07 07 1967 Montreal.19 06 1969 Montreal.20 12 1961 Montreal.04 11 1966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 décembre 1973.105' année.n° 50 7375 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date MOTEL LE SAVOIE INC.NACREN INDUSTRIES LTD.NARP LIMITED.NATIONAL DIESEL LTD.NEBRASKA MEAT COMPANY LTD.LE NETTOYEUR MONTCALM INC.NIRAB INDUSTRIES LIMITED.NOIK BROS.CONSTRUCTION CO.LTD.NORTHERLY INDUSTRIAL CORPORATION NORTHLAND OPTICAL SERVICES INC.O'BRIEN MOTORS LTD.O-CORNET INC.L'OEUVRE DES LOISIRS DE ST-THOMAS DIDYME INC.L'OEUVRE DES LOISIRS ST-JOSEPH DES PATIOS.L'OEUVRE DES LOISIRS DE STE-CROIX INC.P.L.EQUIPEMENT LTEE.PARK LANE FURNITURE INC.THE PATINO MINING CORPORATION.PEINTURES BEL-TONE (QUEBEC) INC.PELLETIER & ASSOCIES INC.LES PHARMACIES MONT ROSE INC.LES PIECES D'AUTOMOBILES MARSEILLES INC.PIGEON SERVICE STATION INC.PLACEMENTS PROBEC INC.LES PLACEMENTS SAINT-MARTIN INC.LES PLACEMENTS SEPT ILES LTEE.PLACEMENTS V.T.V.INC.PLOMBERIE ET CHAUFFAGE G.V.INC.POLGRO INVESTMENT INC.ROGER POMERLEAU AUTOMOBILFB LTEE.THE PONTIAC SOCIAL PLANNING COUNCIL INC.POULET POP INC.PRECISION MACHINING & WELDING INC.J.G.PREVOST ASSURANCES INC.PROCBAR CORP.PRODUCTIONS P.M.D.INC.LES PRODUITS CARDINAL INC.Charlesbourg.Montreal.Montreal.Dorval.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Pointe-Claire.Montreal.St-Thomas Didyme Ville de Petite-Rivière .Lac-à-la-Croix.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal.Montréal.Montréal.Lasalle .Montréal.St-Martin.Sep-Iles.Montreal.St-Janvier.Montreal.Ohomedey .Campbell's.Québec.Jacques-Cartier.Montréal.Deux-Montagnes.Montreal.Mont St-Hilaire.(17\t01\t19G3 25\t08\t1971 30\t07\t1971 09\t02\t196S 25\t10\t1966 23\t04\t1971 24\t05\t1966 22\t09\t1964 06\tH)\t1971 11\t11\t1960 31\t07\t1963 21\t04\t1967 20\t02\t1964 23\t01\t1962 28\t12\t1961 16\t09\t1968 30\t10\t1968 15\t03\t1956 14\t09\t1966 06\t11\t1969 20\t12\t1966 17\t08\t1971 16\t11\t1966 29\t01\t1965 25\t11\t1971 09\t12\t1971 11\t10\t1972 15\t11\t1971 17\t11\t1971 06\t02\t1963 14\t06\t1971 18\t8\t1971 25\t01\t1968 26\t05\t1971 15\t11\t1971 23\t11\t1971 01\t12\t1956 7376 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15.1973.loi.105.No.50 Nom de la compagnie Xante of the company Adresse Address Incorporation Date LES PROMOTIONS SAGUENAY LAC ST-JEAN INC.LES PUBLICATIONS HEBDO-QUEBEC INC.QUARTET PROPERTIES INC.QUEBEC CONSTRUCTION SUBCONTRACTORS ASSOCIATION.QUEBEC CONTRACT DOCUMENTS INC.QUEBEC SCIENTIFIC INSTRUMENTS INC.QUILLES PIE IX (1966) INC.J.M.RAICHE INC.RAYCOMS RADIO INC.LA RECOUSSE.REDMOND & BROS (BIRCH DIMENSION) LTD.REI.EX INTERNATIONAL INC.RENOVATECINC.REPUBLIC FUNDING (QUEBEC) LIMITED.RESIDENCE JEAN DE LA LANDE INC.RESTAURANT COTE DU LAC LTEE.RESTAURANT LA MADELON INC.RESTAURANT MONACO (1967) INC.KESTHAVEN CONVALESCENT HOME LTD.RIVE NORD AUTO INC.RONALD FRUITS ET LEGUMES LTEE JEAN RUFFO LTEE.ST CONSTANT INDUSTRIAL PARK INC.ST JEROME STEEL MFG CO LTD SALON DU GOLF INC.JEAN SANSOUCY LTEE .J.P.ROBERT SAUVE ET ASSOCIES INCORPOREE.SAUVE TRANSPORT INC.SEAWAY NURSERY & LANDSCAPE LTD.SERRES IBERVILLE INC.SERVI CONSULTANTS INC.SERVICE CASTEL LAVAL INC.SERVICE CENTRAL DE CONSTRUCTION JULIEN INC.SERVICE DES LOISIRS ST JACQUES DE MONTREAL.SERVICE DES LOISIRS ST JUSTIN .SHAFFAN DISTRIBUTORS LTD.SHEKWIN CONVERTERS INC Jonquière.Québec.Montreal.Montreal.Montreal .Montreal.Ville St-Michel.Asbestos.St-Jérôme.Québec St-Georges .Montreal .Montreal .Montreal.Montréal .Ste-Thérè.«e-de-Lisieux Gatinenu.Québec.Pointe-Claire .Aux Escoumin-Gatineau Montréal.Montreal.St-Jérome .Montréal .Montréal.St-Jean.St-Tliimothée.C'bâteaugiiay.Iberville Montréal.Québec.Montréal.Montreal.Montréal.Montreal.Montreal.IS\t02\t1963 06\t12\t1971 18\t04\t1968 in\tII\t1964 28\toa\t1962 IS\tii\t1969 20\t11\t1961 14\t05\t1969 28\t08\t1971 27\tin\t1971 20\t06\t101,0 15\tHI\t1971 08\t04\t1964 20\t08\t1964 16\t09\t101,0 ,.s\t11\t1963 30\t04\t1966 20\t11\t1967 27\t01\tlool 22\t06\t1964 27\t04\tI960 07\t07\t1967 07\t04\t1959 02\t03\t1967 25\t05\t1971 12\t11\t1964 24\tId\t1961 30\t12\t1963 13\t06\t1964 18\t01\t1967 19\tn.i\t1970 30\t00\t1966 19\t04\t1966 18\t11\t1968 06\t06\t1966 07\t01\t1972 07\t09\t1967 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7377 SICULA ASSOCIATION OF MONTREAL.SOCIETE DE GESTION MONTBRO INC.SOCIETE JOLUMI INC.SOCIMCO INC.SOUTH SHORE ROOFING & GENERAL CONTRACTING LTD.STEEL MART CORPORATION.SUN WARE (RIVE-SUD) LIMITEE.TECHNICAL CONSULTING SERVICE LTD.TIMBRES UNICO INC.TONI DRESS SHOP & FURS INC.TRANSGLOBAL IMPORTS INC.UNION GENERALE DES ETUDIANTS DU QUEBEC (U.G.E.Q.).THE V.I.P.CLUB OF MONTREAL INC.VO-PRAY INC.WEST ISLAND EQUIPMENT LTD.WRIGHT MACHINE.TOOL & DIE LTD.St-Michel.08 09 1966 Mont-St-Hilaire.22 03 1972 Sherbrooke.27 12 1968 Vanier.01 05 1972 Montreal.06 10 1971 Montreal.03 02 1958 Longueuil.03 12 1971 Verdun.02 08 1968 Montréal.29 12 1965 Coaticook .26 01 1962 Montreal .24 07 1969 Montréal.31 10 1966 Montreal.29 10 1966 Ste-Foy.18 11 1971 Roxboro.08 07 1971 Montreal .19 04 1968 55080-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55080-o Pierre Desjardins.Director of the Companies Service, Erratum Les noms de compagnie énoncés ci-après ont été inclus par erreur dans des avis de lettres patentes annulées dans la Gazette officielle du Québec.En effet, les compagnies concernées ont produit dans les délais fixés les rapports requis par le ministre dans un avis antérieur.En conséquence, vu l'article 5d de la Loi des renseignements sur les compagnies, avis est donné que lesdites compagnies n'ont pas été dissoutes par la publication desdits avis de dissolution.Erratum The names of the companies, hereinafter mentioned have been included by mistake in notices of letters patent annulled published in the Quebec Official Gazette.In fact, the companies concerned have produced, within the prescribed time limits, the reports required by the Minister in a previous notice.Therefore, in compliance with section 5d of the Companies Information Act, notice is given that the said companies have not been dissolved by the publication of said notice of dissolution.Nom de la compagnie Name of the Company Date de constitution Dale of 1 ncorporation Date de lettres patentes annulées Date of letters patent annulled ASSOCIATED PROJECTS INC.M 06 44 20 10 73 AUBIN & ST-PIERRE (DRUMMOND) INC.18 06 70 10 11 73 CANADIAN TRANS-VIDEO INCORPORATED.09 07 62 19 05 73 CLUB AN-GI-LOU INC.\" 06 62 01 12 73 CLUB NEMROD INC.02 09 60 01 12 73 MARCHE CENTRAL (QUEBEC) INC.10 04 59 20 10 73 55080-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb.55080-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date 7378 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Revocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé a propos de faire droit a la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Nom de la compagnie Name of the Company BEAVER MINING CORPORATION.BEN TRANSPORT LIMITEE.CLUB CHASSE-GALERIE.CLUB CONNOR.CLUB DE LA VER END RYE.CLUB DES TROIS PASSES INC.CLUB DU FAISAN DE DRUMMONDVILLE .CLUB MIKI INC.CLUB TINO.LES ENTREPRISES PAQUET INC.ENTREPRISES PARC LAFONTAINE INC.LES IMMEUBLES AUTHIER LTEE.J.B.FILMS INC.QUEBEC TRANSPORTATION BROKERS INC.RESTAURANTS ORLEANS INC.en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution de ladite compagnie.En conséquence, ladite compagnie est censée n'avoir jamais été dissoute en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 55 (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (]>er.sonnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014¦ transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C 2619-73 and its amendments).These headings arc identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.Ill \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).TV\" \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Xon-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 7390 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.V \u2014 Avis des décisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises parelle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement \\o 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS No QCR-351 QCR-353 QCR-354 QCR-355 MCR-406 MCR-497 QCS-221 QCS-225 QOS-227 Date 27-11-73 28-11-73 29-11-73 23-11-73 27-11-73 27-11-73 27-11-73 Requérants Applicants Bulletin 3818-V et 79S9-V BEAUCE EXPRESS INC.Requérante / Petitioner HERVE DROUIN INC.Intimée / Defendant 23109-V LEO BERCERON 7148-V J.E.ROY INC.15-V TRANSPORT D'ANJOU INC.21708-V KRAUS TRANSPORT LIMITED 185S0-V PUROLATER COURIER LTD 21166-V QUEVILLON TRANSPORT EN ltd.17511-V BEN TRANSPORT LIMITEE 15239-V PERRON TRANSPORT LTEE 1-8-7 1-1-135 1-19-2 1-16-20 3-21-29 1-1-97 1-17-7 1-14-103 G.O.Q.page I date 2942 2572 1397 4123 1798 2554 4131 5272 3888 12-05-73 28-04-73 28-07-73 14-07-73 24-03-73 28-04-73 14-07-73 08-09-73 30-00-73 Cause Case Q-2439 4157 2450 Q-244! M-4030 4180 Q-2447 Q-310 Q 2428 Décisions Rejetée / Rejected Accordée / Granted La Commission décrète que cette cause soit confiée au commissaire en séance / 77id Commissio7i orders that this case be entrusted to the com-missioncr on the bench Accordée en partie telle que modifiée / Partly granted as amended Accordée en partie / Partly granted Accordée en partie / Parity granted Rejetée par défaut / Rejected for default Accordée en partie / Partly granted Désistement / Withdrawal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7391 No Date Requérants Applicants Bulletin G.O.Q.page date Cause Case Décisions QPV-173 21-11-73 MCR-504 26-11-73 MCR-507 MCR-509 27-11-73 27-11 73 3480-A LEO DOYON 21466-V DOLLARD PERREAVLT 22279-V RENE LA VIGNE Requérantes-intervenantes / Applicant-inter ce ncrs 15831-V-P-l LIVRAISON L.GRAVEL INC.Intimée / Defendant Requête incidente pour être relevée du défaut d'intervenir / Incidental request to be discharged from default to intervene 22933-V MORGAN DRIVE-AWAY INC.Requérante / Applicant NATIONAL TRAILER CONVOY OF CANADA LTD Intimée / Defendant PERRON TRANSPORT LTEE Intimée/ Defendant MOBILE HOME TRANSFER REG'D Intimée / Defendant LTSLET EXPRESS INC.Intimée / Defendant L.R.TRANSPORT INC.Intimée / Defendant Requête pour être relevée du délai de 6 mois relativement à la décision MCS-178 du 4 septembre 1973/ Requestfor exemption from the 6-month time-limit respecting decision MCS-178 ol September 4.1073 7306-V GAUTHIER TRANSPORT ENRG.Requête pour être relevée du délai de 6 mois / Request for exemption from the 6-month time-limit 1-17-17 4140 14-07-73 2464 5951 13-10-73 M-146 3-16-6 1776 24-03-73 A la suite du désistement de l'opposant.Voyageur Inc.la Commission décide que cette cause soit entendue par le commissaire en séance / Following withdrawal by Voyageur Inc., the opponent, the Commission has decided that this case shall be heard by the commissioner on the bench Accordée / Granted Rejetée / Rejected Rejetée / Rejected 7392 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15, 1973.Vol.105.No.50 No MCR-510 Date 27-11-73 MCR-5I1 27-11 -73 MCR-510 MCR-517 MCR-518 MCS-259 QI'V-170 QPV-171 QPV-172 Requérants A pplicants 29-11-73 29-11-73 29-11-73 29-11-73 21-11-73 22-11-73 23-11-73 Bulletin 5043-V Y.G.MENARD TRANSPORT LTEE Requérante-venderesse Applicant-vendor 3876-V li.P.R.TRANSPORT LIMITEE Requérante-acquéreur / A ppl irant-purchaser 9570-V LAMOTHE QUEBEC INC.Requérante / Applicant 2973-V COUTU EXPRESS LTD Mise en cause/ Mise en cause Requête en irrecevabilité de l'opposition de Jacques Perron / Request for the dismissal of the objection of Jacques Perron 18510-V NORMAND CLOUTIER TRANSPORT INC.Modification de permis/ Modification of permit 20029-V M.GILLES DUVAL Modification de permis ; Modification of permit 23190-V\" BROMONT MOTEUR WAY ENRG.(Henri Laporte & Dave Cahilll 23174-V PEPLOW TRANSPORT INC.Requérante / Petitioner PROVOST CARTAGE INC.Opposante / Opponent 2941-A D-l et 3313-A D-l JEAN-GUY OUELLET ET JACQUES HARVEY Requérants-vendeurs / A pplicant-rendors T.E.S.I.(SAGUENAY) LTEE Requérant-acquéreur / A pplicant-purchaser 219-A D-l et 3313-A D-2 ALEXANDRE GAUTHIER Requérant-vendeur / Applicant-vendor T.E.S.I.(SAGUENAY) LTEE Requérant-acquéreur / A pplicant-purchaser 3155-A D-l 1535-A D-l AUTOBUS COTE-NORD ENRG.Requérant-vendeur / Applicant-vendor 3-21 38 G.O.Q.page date 1920 10-1-79 1 -3-11 1-2-32 1-1-116 31 03-73 2395 23S4 2561 4926 5476 21-05-73 21-04-73 21-04-73 24-08-73 25-08-73 Cause Case M-3651 M-153 22-09-73 43S5 1248 \u2022I 2 2 2 4155 Q-97 Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Q-161 Désistement / Withdrawal Reietée / Rejected Désistement / Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7393 Date 22-11-73 27-11-73 27-11-73 23-11-73 28-11-73 23-11-73 30-11-73 30-11-73 30-11-73 30-11-73 30-11-73 29-11-73 Requérants Applicants LES AUTOBUS TREMBLAY & TREMBLAY INC.Requérant-acquéreur / A pplicant-piircfia icr 2177-A CENTRE DE SKI MONTMORENCY LTEE 3518-A P-l JOSAPHAT BOUCHER Avis de la Commission \" Proprio Mot\" ¦ / Notice * Proprio Motu a by the Commission 691-A LES AUTOBUS DE LA RIVE SUD LTEE Q-1255-DY & 1026-DYV D 1 LOCATION RIVIERE LA GRANDE INC.Q-1216-DY D-l TF STE-FOY TOYOTA INC.Deniande de modification de tarifs / Request for a modification of tariff 919-DYV TRAIN TRAILER RENTALS LIMITED 232S6-V ROBERT CARRIER 17310-V RAOUL ALLEN 23234-V MICHEL TARDIF 22722-V BENOIT GASTONGUAY 9430-V MICHEL LAMONTAGNE 1930-V PROVOST CARTAGE INC.Intimé / Defendant GERARD NOLIN LIMITEE FRANÇOIS NOLIN LIMITEE Requérantes / .4 pplicants Bulletin 1-16-37 3-22-54 3-15-6S 1-14-64 1-19-17 1-12-10 1-14-98 1-16-11 1 14-54 G.O.Q.4808 412S 6127 2070 4916 5587 2072 3876 4402 3602 3886 4119 3873 date 18-08-73 14-07-73 20-10 73 07-04-73 25-08-73 29-09-73 7-04-73 30-06-73 28-07-73 16-06-73 30-06-73 14-07-73 30-06-73 Cause Case Q-47 2435 Q-267 4072 Q-61 Q-191 M-3882 Q-2436 Q-2452 Q-2446 Q-2410 Q-2445 2440 Décisions Accordée / Granteil Accordée / Granted La requête en droit des opposants est rejetée / The daims of the objecting parties are rejected La Commission décrète le remboursement du dépôt de 325.00 effectué par Monsieur Jo-saphat Boucher, avec sa demande de permis spécial No Q-2712-A The Commission orders the repayment of the $25.00 deposit made by Mr.Josaphat Boucher with his request for a special permit No.Q-2712-A Accordée en partie Partly granted Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement / Withdrawal Rejetée / Rejected Accordée telle que modifiée / Granted as amended Rejetée,' Rejected Accordée telle que modifiée / Granted as amended Rejetée, Rejected La Commission déclare ne pouvoir se prononcer sur la question soulevée à l'enquête par les requérantes relativement à l'étendue ( du permis de l'intimée. 7394 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.No.60 No QCR 307 QCR-308 QCR-369 QCR-372 QOS-229 QCS-232 (jrS-233 QL-86 (JCR-363 TF QCR-364 TF QCH-365 Date 3-12-73 3-12-73 3-12-73 5-12-73 3-12-73 4-12-73 5-12-73 3-12-73 30-11-73 30-11-73 Requérants .1 ;.;./l.-.li.l.< Q-4221-V VICTOR TRANSPORT LIMITEE Q-1567-V GUISLAIN LALANCETTE Q-U437-V LTSLET EXPRESS INC.23048-V TRAVERSE M.S.S.LIMITEE Q-8642-V \u2022 .-.-i ; IN EXPRESS LIMITEE 15957-Y GERARD NOLIN LTEE MARC PETITPAS Requérant / Applicant 22077-V ROBERT L.GAUDET Intimé / Defendant Requête en revision de la décision QCS-36 rendue par la Commission en faveur de l'intimé le 30/7/73 et publiée dans les G.O.Q.du 11,8/73.Petition for rerision of decision QCS-36 rendered by the Commission in favour of the defendant on July SO, 1073 and published in the Q.O.G.of August It.I.97J.Q-1189-DV - Q-913-DYV QUEBEC N E\\V FO I'NDLAND EQUIPMENT LTD.Q-22930-V D-l MESSAGERIE D'ALMA ENIt.Demande de modification de tarif.4 pplication for modification of tariff.I50I-V D-l TF ANDRE PAQUET Demande de modification de tarif.Application for modification of tariff.Q-10409-V-P-l LUCIEN IIEON Avis de la Commission « Proprio Motu » Xotiee \"proprio motu\" by the Commission Bulletin 1-20-3 1-20-8 1-19-21 1-10-18 c page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions \t\t\tThe Commission decla- \t\t\tres that it is unable \t\t\tto decide on the matter \t\t\tbrought up by the ap- \t\t\tplicants at the inquiry \t\t\tconcerning the extent of \t\t\tthe defendant's permit.4515\t04-08-73\tQ-2466\tAccordée en partie \t\t\tPartly Granted 3888\t30 1)6 73\tQ-2411\tAccordée en partie \t\t\tPartly Granted 4617\t04-08-73\tQ-2468\tAccordée / Granted 4700\t11-08-73\t2430\tAccordée.' Granted 4403\t28-07-73\tQ-2453\tAccordée / Granted 3218\t26-05-73\t2429\tAccordée / Granted 4632\t11-08-73\t2462\t \t\t\tLa Commission confir- \t\t\tme, à toutes fins que \t\t\tde droit, la décision \t\t\trendue en chnmbro le \t\t\t30/7/73.\t\t\tThe Commission con- \t\t\tfirms, for all legal \t\t\tpurposes, the decision \t\t\trendered in chamber on \t\t\tJuly SO.1973.3246\t26-05-73\tQ-2401\tAccordée Granted 5580\t29 09-73\tQ-186\tAccordée Granted 5773\t06 lo 73\tQ-218\tAccordée Granted 6408\t15-11-73\tQ-321\tLa Commission corrige \t\t\tle nom de Lucien \t\t\tHétu pour celui de \t\t\tLucien Iléon aans sa \t\t\tdécision QCR-204 si- \t\t\tgnifiée au requérant \t\t\tle 27 aofit 1973. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n' 50 7395 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCote\t \t\t\t\t\t\t\tThe Commission sub- \t\t\t\t\t\t\tstitutes the name Lu- \t\t\t\t\t\t\tcien Héon for that of \t\t\t\t\t\t\tLucien HHu, in ils de- \t\t\t\t\t\t\tcision QCR-204 serv- \t\t\t\t\t\t\ted on the applicant on \t\t7966-V\t\t\t\t\tAugust 27, 197S.QCR-366\t3-12-73\t\t\t\t\t\t \t\tALCIDE ST-YVES\t\t4795\t11-08-73\t\tAccordée / Granted \t\tRequérant-vendeur\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-rrndor\t\t\t\t\t \t\tLUCIEN ST-YVES\t\t4725\t11 us 7:1\t\tAccordée / Granted \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tApplicant purchaser\t\t\t\t\t QCR-370\t3-12-73\tQ-7148-V\t\t\t\t\t \t\tJE.ROY INC.\t1-19-2\t4397\t28-07-73\tQ-2450\tAccordée ' Granted QCR-371\t3-12-73\t23I13-V-D-1\t\t\t\t\t \t\tJACQUES FORTIER\t\t5955\t13-10-73\tQ-247\tAccordée / Granted QCR-373\t6-12-73\t4545-V-D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tTRANSPORT LAVOIE\t\t\t\t\t \t\tLTEE\t\t5773\t06-10-73\tQ-2I0\tAccordée / Granted \t\tDemande de fixation de\t\t\t\t\t \t\ttarifs.\t\t\t\t\t \t\tApplication /or firing o!\t\t\t\t\t \t\ttariffs.\t\t\t\t\t MCR-543\t4-12-73\t5858-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tMIDDLE ATLANTIC CONFERENCE.\t\t\t\t\t \t\tAGENT\t\t4913\t25-08-73\t\tAccordée / Granted \t\tDemande de modification\t\t\t\t\t \t\tde tarifs.\t\t\t\t\t \t\tA pplication for modification\t\t\t\t\t \t\tof tariffs.\t\t\t\t\t QCS-230\t4-12-73\t19834-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tGILLES GAUVIN\t\t5952\t13-10-73\tQ-231\tAccordée ; Granted QCS-231\t4-12-73\t19834-V\t\t\t\t\t \t\tMATAGAM1 RI AI>\\ MIX LTD.Voiturier-remorqueur Haulaway operator LES TRANSPORTS DE LA BAIE\t\t\t\t\t \t\tD'HUDSON INC.\t\t5953\t13-10-73\tQ-233\tAccordée / Granted \t\tVoiturier-roulier / Carrier 1949-AE-D-l TF\t\t\t\t\t QPV-177\t3-12-73\t\t\t\t\t\t TF\t\tROBERT DOSTIE Demande de fixation de tarifs.Application for firing of tariffs.\t\t5773\t06-10-73\tQ-217\tAccordée Granted QPV-178\t4-12-73\t3323-A\t\t\t\t\t \t\tAUTOBUS PORTNEUF\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t4428\t28-07-73\tQ-234\tAccordée Granted QPV-179\t4-12-73\t3365-A\t\t\t\t\t \t\tJEAN MALOUIN ft MARCEL ROBERT Requérants- vendeurs Applicant vendors LES AUTOBUS ROBERT LTEE Requérant-acquéreur Appticlnt purchaser\t\t4731\t11-08-73\t\tAccordée Granted QPV-180-\t4-12-73\t3063-AE-D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tAUTOBUS SCOLAIRE\t\t\t\t\t \t\tDROLET LTEE\t\t5770\t06-11-73\tQ-198\tAccordée 1 Granted QPV-181-\t6-11-73\t2077-A-D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tCONRAD CYR Demande de fixation de tarifs.Application for firing of tnriffs.\t\t5951\t13-10-73\tQ-226\tAccordée ' Granted 7396 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 15.1973.Vol.105.No.50 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants Applicants\t\t\t\tCause\tDécisions No\tDale\t\tBulletin\tpage\tdate\tCase\t QL-87\t3-12-73\tQ-1263-DV -\t\t\t\t\t \t\t1037-DYV-D-l BAIE-COMEAl\"\t\t\t\t\t \t\tPLYMOUTH\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tCHRYSLER INC.\t\t4808\t18-08-73\tQ-59\t QL-S8\t4-12-73\t571-DYV-D-l RENE PROULX\t\t5953\t13-10-73\tQ-237\tAccordée / Granted QL-S9\t5-12-73\t681-DYV\t\t\t\t\t \t\tLEVIS CARAVANE ENRO.Requérante-venderesse Applicant vendor CARAVANE LEVIS\t\t\t\t\t \t\tINC.\t1-9-39\t3025\t19-05-73\tQ-1278-L\tAccordée ' Granted \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tAppplicant purchaser S15-DY et 342-DYV-D-1 MAURICE DESRUISSEAUX Requérante-venderesse Applicant vendor LOCATION DE\t\t\t\t\t ML-183\t3-12-73\t\t\t\t\t\t \t\tL'ESTRIE LTEE\t\t5479\t22-09-73\tM-176\tAccordée / Granted \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tApplicant purchaser THREE RIVERS\t\t\t\t\t QSM-I8-TF\t3-12-73\t\t\t\t\t\t \t\tBOATING LTD.Demande de fixation de tarifs.Application for firing of tariffs.\t\t5769\t06-10-73 _!\tQ-197\tAccordée / Granted SÉANCES EN CHAMBRE 'SITTINGS IN CHAMBERS\t\t\t\t\t\t\t QCR-349\t23-11-73\t3662-V\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT THEBERGE LTEE\t\t4399\t28-07-73\t\tAccordée / Granted QCR-360\t26-11-73\tQ-20866-V D-l\t\t\t\t\t TF\t\tLUCIEN PAQUET Demande de modification de tarifs / Request for a modification of tariffs\t\t5587\t29 09-73\tQ-187\tAccordée / Granted QCR 352\t27-11-73\t23159-V\t\t\t\t\t \t\tBENOIT CROTEAU\t\t4708\t11-08-73\t\tAccordée / Granted \t\tLTEE\t\t\t\t\t QCR-356\t29-11-73\t22340-V D-1\t\t\t\t\t TF\t\tSUNBURY TRANSPORT LIMITED\t\t5588\t29-09-73\t191\tAccordée / Granted QCR-367\t29-11-73\tQ-22461-V (D-l)\t\t\t\t\t TF\t\tM.HENRILEVESQUE Demande de modification de tarifs ' Request for a modification of tariffs\t\t4928\t25-08-73\tQ-104\tAccordée / Granted MCR-490\t23 11-73\t23354-V\t\t\t\t\t \t\tPIERRE CLARK\t1-20-31\t4521\t04-08-73\t\tAccordée j Granted MCR-491\t23 -11-73\t23375-V ROGER LEFEBVHE\t\t4727\t11-08-73\t\tAccordée / Granted MCR-492\t23 11-73\t23357-V\t\t\t\t\t \t\tRICHARD\t1-20-19\t4519\t04-08-73\t\tAccordée / Granted \t\tVAILLANCOURT\t\t\t\t\t MCR-493\t23-11-73\t23373-V\t\t\t\t\t \t\tLEANDRE HASLER\t\t4730\t11-08-73\t\tAccordée / Granted MCR-494\t23-11-73\t23371-V\t\t\t\t\t \t\tRENE HOULE\t\t4729\t11-08-73\t\tAccordée / Granted Accordée Granted MCR-495\t23 11 73\t23377-V GARAGE FELIX PAQUETTE LTEE\t\t4727\t11-08-73\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7397 \t\t\t\t(\ti.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tBulletin\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCI! -49S\t\t\t\t\t\t\t MCS-256\t23-11-73\t174-V CANADIAN BAGGAGE\t\t\t\t\t \t\tDELIVERY LTD.\t\t4720\t11-08-73\t\tAccordée / Granted MCR-499\t26 -11-73\t1739-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t\t\t\t \t\tDU QUEBEC INC.\t1-S-p.37\t2938\t12-05-73\t\tAccordée / Granted \t\tDemande de modification\t\t\t\t\t \t\tde tarifs/ Request for a\t\t\t\t\t \t\tmodification of tariffs.Q-23039-V\t\t\t\t\t QCS 226\t27-11-73\t\t\t\t\t\t \t\tSEPT-ILES\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT INC.\t1-1-64\t2541\t28-04-73\tQ-2343\tAccordée / Granted QC8-228\t28-11-73\tQ-15957-V et Q-23086-V GERARD NOLIN LIMITEE Voiturier-roulier/ Carrier DENIS LEBLANC Voiturier-remorqueur /\t1-8-126\t\t\t\t \t\tCarrier.\t127\t2960\t12-05 73\t\tAccordée / Granted \t\tDemande de désistement.\t\t\t\t\t \t\tWithdrawal request.\t\t\t\t\t MCS-257\t23-11-73\t233 U-V INTERCONEX\t\t\t\t\t \t\t(CANADA) 1972 LTD.\t1-19-27\t4406\t28-07-73\t\tIl est décrété que cette requête soit portée an rôle des causes pour être entendue en audience publique / It is ordered that this request be entered on the cause list to be heardata public hearing.MCS-258\t23-11-73\t21958-V LAIDLAW\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT LTD.\t1-14-84\t3882\t30-06-73\t\tAccordée / Granted (JPV-167\t23-11-73\tQ-34-A (D-l)\t\t\t\t\t TF\t\tPAUL TREMBLAY\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT LTEE\t\t5281\t08-09-73\tQ-137\tAccordée / Granted \t\tDemande de modification\t\t\t\t\t \t\td J tarifs / Request for a\t\t\t\t\t \t\tnwdificatif n of tariffs.\t\t\t\t\t QPV-168\t23-11-73\t1176-A D-l MTF\t\t\t\t\t TF\t\tASBESTOS TRANSIT INC.Demande de modification de tarifs / Request for a modification of tariffs.\t\t\t\t\tAccordée / Granted QPY-169\t23-11-73\t73-A D-l MTF\t\t\t\t\t TF\t\tAUTOBUS DES BOIS FRANCS LIMITEE Demande de modification de tarifs / Request for a modification of tariffs.\t\t\t\t\tAccordée / Granted ML-173\t23-11-73\t139-DYL GNC HOMES, Division of\t\t\t\t\t \t\tGNC INDUSTRIES\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tLIMITED\t1-4-65\t2465\t21-04-73\t\t ML-174\t23-11-73\t150-DYL\t\t\t\t\t \t\tINDUSTRIAL GRAIN\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tPRODUCTS LTD.\t1-16-57\t4134\t14-07-73\t\t ML-175\t23 11-73\t773-DYV TRANSFOOD SERVICE REG'D.Requérant-vendeur./ A pplicant-vendor.TRANSFOOD SERVICES (1973) ENRG.Requérant-acquéreur./ .4 pplicant-purchaser.\t\t4790\t18 08-73\t\tAccordée / Granted 7398 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.60 \t\t\t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\t\t\tRequérants\t\t\t\tCause\tDécisions No\tDat\t\t\t\tBulletin\tpage\tdate\t\t \t\t\t\tApplicants\t\t\t\tCose\t ML-176 TF\t26-\t11-\t-73\t456-DYV TRANS-CANADA RENT\t\t\t\t\t \t\t\t\tA TRAILER (1964)\t\t\t\t\tAccordée / Granted \t\t\t\tLTEE\t1-14-116\t3891\t30-06-73\t\t \t\t\t\tDemande de modification\t\t\t\t\t \t\t\t\ttarifs / Request /or a\t\t\t\t\t \t\t\t\tmodification o/ tariffs.\t\t\t\t\t MPV-102\t27-\t11\t-73\t634-A LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE\t\t5599\t29-09-73\tM-238\tAccordée / Granted MPV-103\t27-\t-11\t-73\t1875-A M.RODOLPHE BOISJOLY\t\t5596\t29-09-73\tM-227\tAccordée / Granted MPV-104\t27-\t-11\t-73\t3169-A M.RAYMOND AMYOT\t\t5593\t29-09-73\tM-216\tAccordée / Granted MPV-105\t27-\t-11\t-73\t2871-A M.EDOUARD ALLEN\t\t5594\t29-09-73\tM-217\tAccordée / Granted MPV-106\t27-\t-11\t-73\t1729-A\t\t\t\t\t \t\t\t\tM.ROGER SANTERRE\t\t5594\t29-09-73\tM-220\tAccordée / Granted MPV-107\t27-\t11\t-73\t2888-A M.GERARD\t\t\t\t\t \t\t\t\tTRANCHEMONTAGNE\t\t5595\t29-09-73\tM-221\tAccordée / Granted MPV-108\t27-\t11-\t-73\t2988-A\t\t\t\t\t \t\t\t\tM.JEAN MAUGER\t\t5595\t29-09-73\tM-224\tAccordée / Granted MPV-109\t27-\t11\t-73\t1734-A AUNTIE TOUB'S PRESCHOOL\t\t\t\t\t \t\t\t\tNURSERY\t\t5599\t29-09-73\tM-239\tAccordée / Granted MPV-110\t27-\t-11\t-73\t2711-A M.RUSSELL\t\t\t\t\t \t\t\t\tFOURNIER\t\t5599\t29-09-73\tM-240\tAccordée / Granted Accordée / Granted MPV-11I\t27-\t-11\t-73\t3001-A M.UBALD SOUTIERE\t\t5600\t29-09-73\tM-241\t MPV-112\t27\t11\t-73\t2058-A LES AUTOBUS BOUCHERVILLE INC.\t\t5600\t29-09-73\tM-242\tAccordée / Granted MPV-113\t27\t-11\t-73\t1916-A\t\t\t\t\t \t\t\t\tM.HORST SCHUTZ\t\t5600\t29-09-73\tM-243\tAccordée / Granted Accordée ; Granted MPV-114\t27\t-11\t-73\t1944-A M.WILLIAM B.SCHWARTZ\t\t5600\t29-09-73\tM-244\t MPV-115\t26\t-11\t-73\t754-A CHAMBLY TRANSPORT INC.Intimée / De/endant VILLE DE BROSSARD, VILLE DE GREENFIELD PARK, VILLE DE LONGUEUIL.VILLE DE ST-LAMBERT, VILLE DE LEMOYNE, VILLE DE ST-HUBERT.COLLEGE EDOUARD MONTPETIT Requérantes / Applicants La Commission des transports de la Rive-Sud de Montréal, requérante en intervention relativement .1 la décision MPV-70 TF rendue le 11 octobre 1973 The Commission des Transports de la Rire-Sud de Monlrial.intervening petitioner in connection with\t\t6123\t20-10-73\t\tLa requite de la requérante en intervention à l'effet d'être entendue conjointement avec les requérantes est accordée / The request 0/ the intervening petitioner to be heard jointly with the peti- \t\t\t\tdecision MPV-70 TF ren-\t\t\t\t\ttioners is granted.\t\t\t\tdered on October 11, 197S\t\t\t\t\t MPV-116\t29-\t11\t-73\t97-A D-4 TF\t\t\t\t\t TF\t\t\t\tAUTOBUS DRUM-MONDVILLE LTEE\t\t6217\t27-10-73\tQ-261\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 décembre 1973.105' année.n° 50 7399 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\t.4 pplicants\t\t\t\tCom\t MPV-117\t29-11-73\t2151-A M.ERNEST PLOUFFE Requérant-vendeur Applicant-vendor 3364-A\t\t\t\t\t \t\tM.GUV BELLERIVE\t\t5471\t22 ll'.l 73\tM-178\tAccordée / Granted \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tAppl icant-purehaaer\t\t\t\t\t ML-177\t29-11-73\t1015-DY & 620-DYV GREAT PACIFIC INDUSTRIES LTD.Requérante-venderes.se\t\t\t\t\t \t\t.1 li/i!icant-1 i >ith>/ JIM PATTISON\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\tLEASE LTD.\t1 12-62\t3619\t16-06-73\t\tAccordée / Granted \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-purchaser\t\t\t\t\t MI.ITS\t29-11-73\t455 DYY LESLIE SMITH LEASING LIMITED Requérante-venderesse A pplicant-rendor GENERAL TRAILER\t\t\t\t\t \t\tLEASING\t1-15-22\t3977\t07-07-73\t\tAccordée / Granted \t\t(Robert H.Smye.Leslie\t\t\t\t\t \t\tO.Smithl\t\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t\t MCR-499\t26-11-73\tA pplicant-purchaser 739-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t\t\t\t \t\tDU QUEBEC INC.\t1-8-p.37\t2938\t12-05-73\t\tAccordée / Granted MCR-500\t27-11-73\t1550-V D-l TF\t\t\t\t\t TF\t\tH.LAPALME\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT LTEE\t\t5589\t29-09-73\tM-195\tAccordée,' Granted MCR-501\t27-11-73\tD-42 TFM.11355-V\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.MAISLIN TRANSPORT LIMITEE\t\t\t\tM-196\tAccordée / Granted MCR-502\t27-11-73\tD-41-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t\t\t\t \t\tDU QUEBEC INC.\t\t5589\t29-09-73\tM-197\tAccordée / Granted MCR 503\t27-11-73\tD-40-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t\t\t\t \t\tDU QUEBEC INC.\t\t5589\t29-09-73\tM-198\tAccordée / Granted MCR-505\t27-11-73\t18595-Y D-l-TF\t\t\t\t\t TF\t\tTRANSLAND TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT (1968) INC.\t\t5589\t29 09-73\tM-200\tAccordée,' Granted MCR-506\t27-11-73\t23278-V\t\t\t\t\tDécision intérimaire décrétant une enquête publique / Interim decision ordering a public inquiry.\t\tRHEAUME FORCIER\t\t4725\t11-08-73\t\t MCR-508\t27-11-73\tD-39-TFM\t\t\t\t\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS\t\t\t\t\t \t\tDU QUEBEC INC.\t\t5589\t29-09-73\tM-199\tAccordée / Granted MCR-612\t29-11-73\t1949-V et 1332-V L.WOODS 4 SON TRANSPORT LTD.Rcquérante-cédante .4 pplicant-trans/eror ATLAS TRUCKING\t\t\t\t\t \t\tCO.LTD.\t1-19 54\t4415\t2807-73\t\tAccordée / Granted \t\tRequéran te-cessionna i rc\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-lransfi rre\t\t\t\t\t MCR 513\t29-11 73\tII652-V AIME BERTRAND Requérant-vendeur .4 pplicani-vendor\t\t\t\t\t 7400 QUEBEC nEFICI.il.GAZETTE.December 15.1973.Vol.105, No.50 \t\t\t\tC.O.O.\t\t\t No\tDate\tRequérants A pplicants\tBulletin\tpage\tdate\tCause Case\tDécisions \t\tF.DESLIPPF.S\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT ENRG.\t\t\t\t\t \t\t(F.Deslippes & Jean-Guy Benurhanip)\t1-19 57\t441S\t28-07-73\t\tAccordée / Granted \t\tRequérants-acquéreurs\t\t\t\t\t \t\tA ppticanl-purchasers\t\t\t\t\t MCR-614\t29-11-73\t1332-V et 1949-V ¦ ATLAS TRUCKING CO.LTD.Requérante-cédante A ppticant-transferor\t\t\t\t\t \t\tL.WOODS A SON TRANSPORT LTD.\t1-19-74\t4425\t28-07-73\t\tAccordée / Granted \t\tRequérante-cessionnaire\t\t\t\t\t \t\tApplicant-transferee\t\t\t\t\t MCR-515\t29-11-73\t1538-V\t\t\t\t\t \t\tGEORGES 0.DUBOIS\t\t\t\t\tDésistement ,' \t\tINC.\t\t4719\t11-OS-73\t\t \t\t\t\t\t\t\tWithdrawal MCR-549-\t06-12-73\tBUREAU DES TARIFS\t\t6425\t03-11-73\tM-424\tLa Commission accepte TF\t\tDU QUEBEC INC.Demande de modification de tarifs re: Application for modification of tarifa rc: Supplément d'Ordre gé-\t\t\t\t\tl'augmentation proposée, fixe et décrète en vigueur a compter du 3 janvier 1974.le supplément d'Ordre général, modifié, savoir: \t\tnéral No 34\t\t\t\t\tThe Commission agrees to the proposed in \t\tGeneral Order Supplement\t\t\t\t\t \t\tXo.34\t\t\t\t\tcreases, fixes and orders \t\t\t\t\t\t\tthe coming into force, on January 3.1974 of the Supplement to General Order, modified, name-to 7% de 0 à 75 milles 9% au-dessus de \"S milles et $0.50 sur les minima.from 0 to 75 miles: 7% over 76 miles: 9% and SO.ÔO on minimum « harges.PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permits QS-100 15-V S-2\tTRANSPORT DANJOC INC.\tG mois ou jusqu'à décision finale ti months or until final decision\tPermis spécial - Le voiturier-roulier a l'autorisation d'utiliser pour le transport de marchandises autorisées par les clauses a et 6 de son permis les services de remorquage de : Philippe Richard Ltée, No 15251-V.Charles Stuart.No 23026-V.Georges Le bel, No 23369-V.AurMe Durepos.No 23524-V, Roger Clavette.No 23525-V / Special permit - The carrier has the authorization to utilize, for the transportation of goods authorized by clause» a and b of its permit, the haulaway services of: Philippe Richard.No.IS25I-V.Charles Stuart, No.2S0S6-V.Georges Lebel, No.83S69-V', Aurtle Durepos, No.23584-V.Roger Clarctte, No.SSfiSS-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105* année, n\" SO 7401 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant QS-101 15251-V S-2 QS-102 23026-V S-2 QS-103 23369-V S-I QS-104 23524-V S-l QS-105 23525-V S-l QS-106 23099-V S-l QS-107 6793-V S-l ns iris 19459-V QS-109 1372-V S-l QS-110 22499-V S-3 QS-I1I 1389-A S-l PHILIPPE RICHARD LTEE CHARLES F.STUART GEORGES LEBEL AURELE DUREPOS ROGER CLAVETTE LES ENTREPRISES M.T.V.ENRG.BRAZEAC TRANSPORT INC.GERARD BARON TRANSPORT LACHANCE ENRG.LES TRANSPORTS DE LA BAIE DHL'DSON INC.Demande entendue en séance publique / Request heard at a public hearing AIR LINES TAXIS & BISSES REG'D Validité: de:.à: Validity Period 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final decision 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final decision 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final decision 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final, decision 6 mois ou jusqu'à décision finale 6* months or until final decision 6 mois / G months 6 mois / 6' months 3 jours à compter de la date de signification de la présente 3 days from the date of ratification of the presents jusqu'au 31 octobre 1974 Until October 31.1974 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final decision Détails du permis Particulars Permis spécial - Le détenteur a l'autorisation de remorquer, selon les clauses c et 6 du permis No 15-V pour le compte de Transport d'Anjou Inc./ Special permit - The holder has tht'authorization to haul, according to clauses a and b of permit No.15-V, on behalf of Transport d'Anjou Inc.Permis spécial - Le détenteur a l'autorisation de remorquer, selon les clauses a et b du permis No 15-V, pour le compte de Transport d'Anjou Inc./ Special permit - The holder has the authorization to haul, according to clauses a and b of permit No.15-V, on behalf of Transport d'Anjou Inc.Permis spécial - Le détenteur a l'autorisation de remorquer, selon les clauses a et 6 du permis No 15-V, pour le compte de Transport d'Anjou Inc./ Special permit - The holder has the authorization to haut, according to clauses a and b of permit No.15-V, on behalf of Transport d'Anjou Inc.Permis spécial - Le détenteur a l'autorisation de remorquer, selon les clauses a et b du permis No 15-V, pour le compte de: Transport d'Anjou Inc./ Special permit - The holder has the authorization to haul, according to clauses a and b of permit No.15-V, on behalf of; Transport d'Anjou Inc.Permis spécial - Le détenteur a l'autorisation de remorquer, selon les clauses a et b du permis No 15-V pour le compte de: Transport d'Anjou Inc.! Special permit - The holder has the aidhor-ization to haul, according to clauses a and b of permit No.15-V, on behalf of: Transport d'Anjou Inc.Permis spécial - Autorisation de remorquer, pour le compte de Brazeau Transport Inc.I Special permit - Authorization to haul, on behalf of lira-zeau Transport Inc.Permis spécial - Autorisation d'utiliser le service de remorque de: Les Entreprise:* M.T.V.Enrg./ Special permit - Authorization to utilize the haulaway service of: Les Entreprises M.T.V.Enrg.Permis special - Autorise Gérard Baron à déplacer une remorque surbaissée de St-Ro-muald à St-Thécle, pour le compte de Machinerie Laçasse Inc./ Special permit - Authorises Gérard Baron to more a low-bed trailer from St.Romuald to St.Thecle, on behalf of Machinerie Laçasse Inc.Permis spécial - Demande de permis spécial / Special permit - Application for a special per mit.Rejetée / Rejected.Permis spécial - De Matagami à tous les points de la municipalité de la Baie-James pour remorquer des roulottes, maisons mobiles et tons véhicules similaires / Special permit - From Matagami to all points in the Municipality of James Bay to haul trailers, mobile homes and all similar vehicles.Classe de permis: Autobus, Service No 1 : Permis spécial - Transport à tant par téte.restreint aux voyageurs partant ou arrivant, par avion, entre le ï'hâteau Frontenac à Québec à l'Aéroport de Ste-Foy, et vice-versa, avec arrêt au Château Laurier, à la rue Holland, à l'Université Laval et au Congress Inn. 7402 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 No du répertoire chronologique Chronological Repertory So.QS-112 644-DYV S-l MS-295 2957-A S-l Nom du requérant Xante of Applicant Validité: de:.à: Validity Period ATRIUM LEASING INC.RIVERAINS TRANSPORT INC.MS-296 AUTOBUS LEO AUGER INC.1878-A 8-8 MS-297 2594-A S-2 MS-290 2594-A S-3 MS 2iHi 528-V S-l MS-300 12-DYL S 1 METROPOLITAIN SUD (1967) INC.METROPOLITAIN SUD (1967) INC.WM.C.NORRIS LTD.CANADIAN LIQUID AIR LTD.3 semaine» à compter du 15 novembre 1973 3 weeks from November là, 1973 C mois à compter de vendredi ou jusqu'à décision finale de la Commission G months beginning Friday or until the final decision of Commission Détails du permis Particulars Classe de permis: Taxis.Service No 2: Transport, à tant par tête, restreint aux voyageurs partant ou arrivant, par avion, entre le Château Frontenac à Québec et l'aéroport de Ste-Foy, et vice-versa, avec arrêt au Château Laurier, à la rue Holland, à l'Université Laval et au Congress Inn.Class of permit: Bui.Service No.1: Special permit - Transportation at a fixed rate per person, restricted to passengers leaving of arriving by airplane, between Château Frontenac in Quebec and Ste.Foy Airport, and vice-versa with stops at; Château-Laurier, Holland Street, Laval University and Congress Inn.Class of permit: Tazicab.Service No.2; Transportation at a fixed rate per person, restricted to passengers leaving or arriving by airplane, between Château Frontenac in Québec and Ste.Foy Airport, and vice-versa, with stops at: Château Laurier, Holland Street, Laval University and Congress Inn.Permis spécial - Demande de permis spécial / Special permit - A p plication for a special permit.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Transport d'écoliers de Longueuil, Laflèchc-Ville Lemoyne-Greenfield Park et St-Lamhert A Ec.Sec.Jean-de-la-Mennais et retour / Special permit - Transportation of students from Longueuil, Laflèche-Town of Lemoyne-Greenfield Park and St.Lambert to Jean-de-la-Mennais Secondary School and return.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Transport charte-partie de Beau-harnois / Special permit - Charter transportation from Beavharnois.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Autorisation de percevoir un tarif de ?0.30 du passage pour prolongement de service jusqu'à Montréal durant la grève de la C.T.C.U.M./ Special permit - Authorization to collect a fare of S j.30 per passenger for the extension of its service to Montreal during the M.U.C.T.C.strike.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Autorisation de continuer jusqu'à Montréal durant la grive de la C.T.C.U.M.du Métro Longueuil.' Special permit - Authorization to extend its ecrviee to Montreal during the M.U.C.T.C.strike, from Longueuil Metro.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Location de la Cie Triad Truck-lease Québec Ltd., l'unité No 729-2 1972 licence FX-4658, pour remplacer l'unité No 303 International Harvester / Special permit - Leasing from Cie Triad Trucklease Quebec Ltd.of 1972 unit No.739-2.license No.FX-4GÔS, to replace International Harvester unit No.303.Permis spécial - Location d'une remorque, numéro de série DXK-778204.à Matthew Francis Donovan, permis No 23437-V / Special permit ~ Lease a trailer serial No.DXK-778204 to Matthew Francis Dona-ran.permit No.23437-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7403 No du répertoire chronologique Chronological Repertory ATo.MS-301 6793 V S-9 MS-302 23467-V S-3 MS-303 11237-V S-l MS-304 16057-V S-3 MS-305 23494-V S-l MS-306 18363-V S-2 MS-307 13963-V S-4 Nom du requérant Xame of Applican t BRAZEAU TRANSPORT INC.M.GERARD ROY W.MOSES INC.H.G.SNYDER TRUCKING INC.M.ALLAN FINLAYSON OIL & INDUSTRY SUPPLIERS LTD.SPEEDWAY EXPRESS LTD.MS-308 23511-V S-l MS-309 292-\\' S-l M.RAYMOND MASSE TYLER TRANSPORT LTD.Validité: de:.à: Validity Period 6 mois ou jusqu'à décision finale de la Commission 6 months or until final decision of the Commission 6 mois ou jusqu'à décision finale de la Commission 6 months or until final decision of the Commission.12 jours à compter du 16 novembre 1973 12 days from Xovember 16, 1973 5 jours à compter du 16 novembre 1973 5 days from Xovember 16, 1973 Détails du permis Particular 6 mois à compter du 15 novembre ou jusqu'à décision finale de la Commission 6 months from Xovember 15 or untU final decision of the Commission G mois ou jusqu'à décision finale de la Commission 6 months or until final decision of the Commission Permis spécial - Courtier - Haulaway avec Gérard Roy.permis No 6793-V / Special permit - Broker - Haulaway with Gérard Roy, permit Xo.6793-V.Permis spécial - Autorisation de remorquer avec ses tracteurs les remorques vides ou remplies de Brazeau Transport Inc.permis No 6793-V / Special permit - Authorization to haul, with his tractors, the (empty or loaded) trailers of Brazeau Transport Inc., permit Xo.6793-V, Permis spécial-Location d'un camion Ryder pour remplacer un Dodge 1969 doit servirsur contrat Sun Oil Co.Ltd./ Special permit - Leasing of a Ryder truck to replace a 1969 Dodge to be used under contract with Sun Oil Co.Ltd.Permis spécial - Location d'un camion International 1973.licence No FX-7294 de Rvder Truck Rental Can.Ltd.permis No 109-DYV / Special permit - Leasing of a 1973 International truck, license Xo.FX-7294 from Ryder Truck Rental Can.Ltd.permit Xo.109-DYV.Permis spécial - Transporter comme camionneur à contrat pour le compte de Léo Tremblay Inc.permis No 12425-V / Special permit - To transport as a contract carrier trucker on behalf of Léo Tremblay Inc., permit Xo.12425-V.Rejetée / Rejected.Permis special - Transport d'additifs pétrolifères liquides de St-Louis.Missouri, U.S.A.à destination de Québec et Montréal / Special permit -Transportation of liquid oil additives from St.Louis, Missouri, U.S.A.to Québec and Montreal.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Courtier haulaway avec Raymond Masse, permis No 23511-V / Special permit - Haulaway operator with Raymond Masse, permit Xo.23511-V.Permis spécial - Autorisation de remorquer avec ses tracteurs Speedway Express Ltd., permis No 13963-V / Special permit - Authorization to haul, with his Speedway Express Ltd.tractors, permit Xo.13903-V.Permis spécial - Transport de la frontière Québec-Ontario à Montréal et retour - Special permit -Transportation from the Québec-Ontario border to Montreal and return.Ilejetée / Rejected. 7404 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol 105, No.50 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-310 QCF-2486-S-1 MS 311 QC'F-2486 MS-312 1930-V S-! MS-313 1930-V S-2 MS-314 1093-DV S-l MS- 315 257-V S-3 MS-316 257-A S-4 MS-317 153-D YL 8 1 Nom du requérant Xante of A pplicant CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N MIDDLE ATLANTIC CONFERENCE PROVOST CARTAGE INC.PROVOST CARTAGE INC.BOULEVARD DODGE CHRYSLER (1963) LTEE TREMBLAY EXPRESS LTD.TREMBLAY EXPRESS LTD.DUPONT DU CANADA LIMITEE Validité: de:.à: Validity Period jusqu'au 1er mai ou jusqu'à décision finale de la Commission tlntû May 1 or until final decision of the Commission.jusqu'au 1er mai 1973 ou jusqu'à décision finale de la Commission Until May 1.1973 or until final decision of the Commission jusqu'au 1er novembre 1974 ou décision finale de la Commission Until Xovember 1, 1974 or final decision of the Commission jusqu'au 1er novembre 1974 ou décision finale de la Commission Until Xovember 1, 1974 or final decision of the.Commission 6 mois ou jusqu'à décision finale de la Commission 6 months or until final decision of the Commission jusqu'au 1er novembre 1974 ou décision finale de la Commission Until November /.1974.or final decision of the Commission Détails du permis Particulars Permis spécial - Autorisation de modifier le tarif en vigueur C.T.T.B.Tarif No 32G, applicable au fer et à l'acier, item 330.483 / Special permit - Authorization to modify the current tariff, C.T.T.B.Iron and Steel Tariff Xo.32G, Item 330, 483.Permis spécial - demande de fixation de taux, tarif S-295-C / Special permit - Application for fixing of rates, tariff S-29Ô-C.Permis spécial - Droit adaitionnel aux clauses d et e du permis 1930-V - d'utiliser les remorques citernes louées de Canadian Industries Limited pour le transport de peroxyde d'hydrogène / Special permit - Additional right to clauses d and e of permit 1930-V - to utilize tank trailers leased from Canadian Industries Limited for the transportation of hydrogen peroxide.Permis spécial - Droit additionnel aux clauses d et / du permis 1930-V d'utiliser les remorques citernes louées de DuPont du Canada Limitée pour transport de peroxide d'hydrogène / Special permit - Additional right to clauses d and f of permit 1930-V to utilize the tank trailers leased from DuPont of Canada Limited for the transportation of hydrogen peroxide.Permis spécial -\u2022 Location de véhicules de promenade aux clients seulement qui attendent la livraison d'un véhicule neuf ou qui est en réparation./ Special permit - Leasing of pleasure vehicles only to customers who are wailing for the delivery of a new vehicle or of a vehicle under repair.Permis spécial - Demande de location de véhicules de Ryder Truck Rental Ltd./ Special permit -Application for leasing of vehicles from Ryder Truck Rental Ltd.Rejetée/ Rejected.Permis spécial - Demande de location de Ryder Truck Rental Ltd.pour des véhicules/Special permit - Application for the leasing of vehicles from Ryder Truck Rental Ltd.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Location de trois remorques l'Hoir Inc.- semi-remorque citerne R.D.Cole Co.semi-remorque-citerne T.V.P.- semi-re-morque-citerne à Provost Cartage / Special permit - Leasing of three trailers of l'Hoir Inc.R.D.Cole Co.Tank-type semi-trailer - T.V.P.tank-type semi-trailer - tank-type semi-trailer to Provost fartage. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7405 No flu repertoire chronologique Chronological Repertory Xo.MS-318 23301-V S-l QS-113 22753-V-S-l QS-114 23413-V-S-2 OS-115 10-N-S-l Cause Q-121 QS-116 23113-V-l QS-U7 11247-V-S-l QS-118 23324-V-S-l Nom du requérant Xame of Applicant NEIL'S BAKERY PRODUCTS TRANSPORT LTD.ANGELO PILLION CHARLES- E UGENE G U A Y SOCIETE DES TRAVERSIERS QUEBEC-LEVIS JACQUES PORTIER PIERRE PRATTE LUCIEN TREMBLAY Validité: de:.à: Validity Period 0 mois ou jusqu'à décision finale 6* month\" or until final decision.0 mois ou jusqu'à décision finale 6\" months or until final decisio/t 6 mois ou jusqu'à décision finale G months or until final decision Détails du permis Particulars of permits Permis spécial - Transport de la frontière Québec-Etats-Unis à tous les endroits de la province de Québec, pour le transport de produits de boulangerie à tous les Restaurants MacDonald / Special permit - Transport from Québec-U.S.A.border to all points in the province of Québec, for the transportation of bakery products to all MacDonald Restaurants.Rejetée / Rejected.Permis spécial - Le détenteur est autorisé à tirer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques et fardiers, selon le?clauses c à z aa à zz, aaa à ///, ainsi que selon les clauses temporaires et expérimentales ggg, hhh et ut accordées le 14/2/73.du permisNo $6793-V pour le compte de: Brazeau Transport Inc./ Special permit - The permit-holder is authorized to haul trailers and floats with his duly-registered tractors, according to clauses c to z, aa to zz, aaa to Iff, and also according to temporary and experimental clauses ggg, hhh and iii granted on February 14.1973, of permit No.67P3-V, on behalf of : lirazeau Transport Inc.Permis spécial - Le détenteur est autorisé à remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques et fardiers, selon les clauses c kz.aa à zz, aaa à///ainsi que selon les clauses temporaires et expérimentales ggg.hhh et iii accordées le 14/2/73.du permis No 6793-V pour le compte de: Brazeau Transport Inc./ Special permit - The permit-holder is authorized to haul trailers and floats with his duly-registered tractors, according to clauses c to \u2022/., aa to zz.aaa to Hi of permit No.6798- V and also according to temporary and experimental clauses pgg, hhh and iii granted on February 14, 1973, on behalf of': Brazeau Transport Inc.Autorisation / Authorization, La Commission autorise la requérante à discontinuer son service entre Québec et Levis en s'assurant qu'un service terrestre d'urgence le remplace jusqu'au moment où lesdits quais pourront permettre l'accostage normal des bateaux traversiers / The Commission authorizes the applicant to discontinue its service between Québec and Levis, provided it ascertains that an emergency land service replaces said service until the piers are in such condition as to permit the normal docking of the ferries.Demande de permis spécial - rejetée / Application for special permit - rejected.Demande de permis spécial - Rejetée / A pplica-lion for special permit - Rejected.Le détenteur est autorisé à tirer les remorques de Branzeau Transport Inc.selon les clauses c à /// inclusivement du permis No 6793-V de ce dernier, ainsi que selon les clauses du permis temporaire expérimental émis en date du 14 février 1973 (permis No 6793-V, The permit-holder is authorized to haul the trailers of carrier Brazeau Transport Inc.according to clauses c to fff inclusive of the latter's permit Xo.6793-V and also according to the clauses of the temporary and experimental permit issued on February 14, 1973 (permit Xo.6793-V. 7406 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973.Vol.105, No.50 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à: Chronological Repertory Xo.\tXame of Applicant\tValidity Period QS-119 23530-V-S-l\tGUY CHOUINARD\t6 mois ou jusqu'à décision fiiule Il months or tmtil final decision QS-120 443-V-S-l\tHARVEY TRANSPORT LIMITEE\t QS-121 147-Y-S-3\tGOSSELIN TRANSPORT\tJusqu'au 28/ 10/74 ou jusqu'à décision finale Until 28110174 or until final decision QS-122 23558-V-S-l 6793-V\tRENE DUBOIS BRAZEAU TRANSPORT INC.\t6 mn'is J 6 months Détails du permis Particulars Le détenteur est autorisé à remorquer des remorques selon les clauses c à/// inclusivement, ainsi que selon les clauses du permis temporaire expérimental émis en date du >4 février 1P73 du permis No 6793-V, pour le compte de: Brazeau Transport Inc./ The permit-holder is authorized to haul trailers according to the clauses c to fff inclusive permit -Vo.6793-V, and also according to the clauses of the temporary experimental permit issued on February 14, 1973, on behalf of: Brazeau Transport Inc.Demande automation de louer à long terme, de Rvder Truck Rental Limited, permis No 109-DYV, les véhicules suivants: 2 tracteurs Int.1972, 2 pick-up Int.1972.2 remorques l'ruehauf 1972 - Rejetée / Application for authorization to lease, on a long-term basis, from Ryder Truck Rental Limited, permit Xo.109-DYV, the following vehicles: 2 Int.1972 tractors.2 Int.1972 pick-ups.2 Fruehavf 1972 trailers - Rejected.Autorisation de louer à long terme (60 mois) de Ï.A.C.Limitée, permis No 508-DYV, un (1) camion-tracteur dont la description apparaît au contrat de location déposé à la Commission/ Authorization to lease, on a long-term basis (60 months), from l.A.C.Limitée, permit Xo.508-DYV, one (1) tractor truck described in the lease filed with the Commission.René Dubois est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques et fardiers de Brazeau Transport Inc., No 6793-V.selon les clauses e à z.aa à zz.aaa à ///, ainsi que les clauses ggg.hhh et iii temporaires et expérimentales accordées le 14 février 1973 dudit permis No G793-V / René.Dubois is authorized to haul, >rith his duly-registered tractors, the trailers and floats belonging to carrier Bra:eau Transport Inc.Xo.6793-V.according to clauses c to z, aa to zz, aaa to fff.and according to temporary and experimental clauses ggir, hhh and iii of said permit Xo.9 6793-V.granted on February 14.U/73.Décision de la Commission des transports du Québec concernant la fixation des taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi MPT-l-TF Conformément au règlement numéro 6 entré en vigueur le 1er novembre 1973.la Commission des transports du Québec doit fixer les taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi sur tout le territoire de la province de Québec.A cette fin.audience publique a été tenue devant un quorum de la Commission des transports siégeant à Montréal, le 19 novembre 1973 et devant un autre quorum siégeant à Quéltec.le 21 novembre 1973 et ce, à la suite d'un avis public paru dans la ('azette officielle du 3 novembre invitant toute personne désirant être entendue sur cette question à se présenter à l'une ou l'autre audience.Decision of the Québec Transport Commission respecting the fixing of rates and tariffs for transportation by taxicab MPT-l-TF In conformity with Regulation number 6, which came into force on November 1, 1973, the Québec Transport Commission must fix rates and tariffs for transportation by taxicab throughout the territory of the Province of Québec.A public hearing was held for this purpose before a quorum of the Transport Commission sitting in Montreal, on November 19, 1973 and before another quorum sitting in Québec, on Xovember 21, 1973, the foregoing following the publication of a notice in the Québec Official Oazette dated November 3, inviting any person wishing to be heard on such matter to attend either one of the hearings. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7407 La Commission, par la suite, a délibéré sur le tout; Considérant les normes de taux et tarifs prévues au Chapitre III du règlement numéro 6 sur le transport par le véhicule-taxi; Considérant que la Commission doit avant le 1er décembre 1973 fixer les taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi dans des normes établies par ledit règlement; Considérant que la preuve et les représentations faites lors des séances publiques ne justifient pas la Commission des transports du Québec de majorer les taux et tarifs prévus à l'avis publié dans la Gazelle officielle du 3 novembre, sauf en ce qui concerne le service extérieur; Pour ces motifs, la Commission fixe les taux et tarifs suivants, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 1974: The Commission has thereafter deliberated on the matter: Considering the standard rates and tariffs provided under Chapter III of Regulation number 6 respecting transportation by taxicab; Considering that the Commission must, prior to December 1, 1973, fix the rates and tariffs for transportation by taxicab according to the standards established by said Regulation; Considering that the evidence and remonstrances presented at the public hearings do not justify an increase, by the Québec Transport Commission, in the rates and tariffs contemplated in the notice published in the Québec Official Gazelle of November 3, save and except as regards service outside limits; On these grounds, the Commission fixes the following rates and tariffs, which shall become effective on January 1, 1974: I \u2014 Agglomérations: véhicules-taxis avec taximètre \u2014 service local / Conglomerations: Taxi-cabs with taximeter \u2014 local service Numéro Pour l'agglomération de: Number For Ihe conglomeration of: b) Pour chaque mille parcouru (b) For each m He travelled A.A A.A.A.A A.A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 Boucherville.Longueuil.Candiac-Laprairie.Cowansville.Est de / East of Montréal.Juliette.I.achute.Laval.Matane.Mont Joli.Montréal.Ouest de / Weft of Montreal Ri vière-du-Loup.St-Eustache.St-Jérôme.Sorel.Terrebonne.Thetford Mines.Victoriaville.a) Au départ de la chute (a) Minimum departure tariff Groupe 1 / Group I $0.50 $0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0 50 0.50 c) Pour chaque minute d'attente (c) For each minute of trailing SO 10 0.10 0.10 0 10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 A.20 Alma.A.21 Baie-Comeau.A.22 Haute-Rive.A.23 Beloeil.A.24 St-Bruno.A.25 Charlesbourg-Orsainville.A.26 Châteauguay.A.27 La Baie.A.28 Dolbeau-Mistassini.A.29 Drummond ville.A.30 L'Est du / East of Québec (iroupe 2 ; Group 2 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 7408 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1073, Vol.105, No.50 Numéro Pour l'agglomération de: Number For Ihe conglomeration o}: A .31 Gaspé.A 32 Giffard.A.33 Granby.A.34 Hull.A.35 Lévis-Lauzon.A.36 Québec.A.37 Rimouski.A.38 Ste-Foy, Sillery.A.39 St-Hyacinthe.A.40 Trois-Rivières.A.41 St-Jean.A.42 Shawinigan.A.43 Sherbrooke.A.44 Valleyfield.a) Au départ de la chute (aj Minimum departure tariff 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 6) Pour chaque mille parcouru (b) For each mile travelled 0.50 0.60 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 c) Pour chaque minute d'attente (c) For each minute of icaiting 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0 10 0.10 0.10 0.10 0 10 0 10 0.10 0 10 0.10 Groupe 3 / Group S A.45 Amos.0.70 0.50 0.10 A.46 Chibougamau.0.70 0.50 0 10 A.47 Matagami.0.70 0.50 0.10 A.48 Rouvn-Noranda.0.70 0.50 0.10 A.49 Val d'Or.0.70 0.50 0.10 Groupe 4 / Group 4 A.50 La Tuque.0.80 0.50 0 10 A.51 L'Ouest du / West of Saguenay 0.90 0.60 0.10 A 52 Saguenay.0.90 0.60 0.10 Groupe 5 / Group 5 A.53 Sept-îles.1.00 0 50 0 10 n \u2014 Régions: véhicules-taxis avec taximètre service local 1.a) Dans le territoire compris dans les limites des municipalités de comté de Témiscamingue et d'Abitibi.6) Dans le territoire ainsi délimite: à l'ouest, la frontière de l'Ontario jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 55.00 nord \u2014 au nord, une ligne orientée est suivant le parallèle 55.00 jusqu'à l'intersection d'une ligne constituée par le prolongement vers le nord de la limite ouest du comté municipal de Saguenay \u2014 à l'est, la limite nord-ouest du comté municipal du Lac St-Jean-Ouest et la ligne constituée par le prolongement vers le nord de la limite ouest du comté municipal de Saguenay \u2014 au sud, la limite nord du comté municipal de l'Abitibi.c) Dans les municipalités de cités et villes comprises géographiquement à l'intérieur du territoire visé aux paragraphes a et b.II \u2014 Regions: Taxicabs with taximeter local service 1.(a) In the territory comprised within the limits of the County Municipalities of Témiscamingue and Abitibi.(b) In the territory bounded as follows: on the west, by the Ontario border up to the intersection of the parallel of latitude 55.00 north \u2014 on the north, by a line extending in an easterly direction along parallel 55.00 up to the intersection of a line formed by the extension towards the north of the west limit of the Municipal County of Saguenay \u2014 on the east, by the northwest limit of the Municipal County of Lake St.John-West and the line formed by the extension towards the north of the west limit of the Municipal County of Saguenay \u2014 on the south, by the north limit of the Municipal County of Abitibi.(e) In the town and city municipalities geographically comprised within the territory contemplated in paragraphs a and b.a) au départ de la chute.$0.70 b) pour chaque mille parcouru.0.50 (o) Minimum departure tariff (b) For each mile travelled $0.70 0.50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7409 2.a) Dans le territoire compris dans les limites des municipalités de comté de Levis, Portneuf, Québec, Montmorency I, Montmorency II, Charlevoix-Est.Charlevoix-Ouest, Chicoutimi, Lac St-Jean-Est, Lac St-Jean-Ouest et Saguenay à l'exclusion du district électoral de Duplessis.b) Dans les municipalités de cités et villes comprises géographiquement à l'intérieur du territoire visé au paragraphe a.a) au départ de la chute.$0.60 6) pour chaque mille parcouru.0.50 3.a) Dans le territoire compris dans les limites du district électoral de Duplessis qui se trouve dans les limites de la municipalité de comté de Saguenay.b) Dans les municipalités de cités et villes comprises géographiquement à l'intérieur du territoire visé au paragraphe a.a) au départ de la chute.$1.00 b) pour chaque mille parcouru.0.50 4.a) Dans le territoire compris dans les autres municipalités de comté de la province de Québec.b) Dans les municipalités de cités et villes comprises géographiquement à l'intérieur du territoire visé au paragraphe a.a) au départ de la chute.$0.60 b) pour chaque mille parcouru.0.50 5.Pour tous les permis de catégorie « région » lorsqu'un véhicule est muni d'un taximètre.pour chaque minute d'attente.$0 10 LTI \u2014 Véhicules-taxis sans taximètre service local Pour chaque mille parcouru.$0.50 IV \u2014 Service extérieur Dans le cas d'une course dont le lieu d'origine ou la destination finale est située à 10 milles ou plus des limites de la région ou de l'agglomération à laquelle le permis se rapporte, ou à plus de 10 milles de la conurbation dont fait partie l'agglomération à laquelle le permis se rapporte: a) Pour un parcours ou une partie de parcours: i) situé à l'est d'une ligne tirée de l'agglomération d'Alma à l'agglomération de l'ouest du Saguenay à la région de St-Siméon-de-Charlevoix-Est; et sur la rive nord du St-Laurent à l'est de cette ligne, ou ii) situé dans les comtés de Témiscamingue et d'Abitibi ou au nord de ces comtés: $0.50 pour chaque mille parcouru.b) Pour un parcours ou une partie de parcours non compris dans le territoire décrit au paragraphe a: $0 40 pour chaque mille parcouru.2.(a) In the territory comprised within the limits of the County Municipalities of Levis, Portneuf, Quebec, Montmorency I, Montmorency II, Charlevoix-East, Charlevoix-West, Chicoutimi, Lake St.John-West and Saguenay except for the Electoral District of Duplessis.(6) In the city and town municipalities geographically comprised within the territory contemplated in paragraph a.(a) Minimum departure tariff.$0 60 (6) For each mile travelled.0.50 3.(a) In the territory comprised in the limits of the Electoral District of Duplessis which is located within the limits of the County Municipality of Saguenay.(6) In the city and town municipalities geographically comprised within the territory contemplated in paragraph a.(a) Minimum departure tariff.$1.00 (6; For each mile travelled.0.50 4.(a) In the territory comprised in the other county municipalities of the Province of Québec.(6) In the city and town municipalities geographically comprised within the territory contemplated in para- graph a.(a) Minimum departure tariff.$0.60 (o) For each mile travelled.0.50 5.For all permits of the \"region\" category when a vehicle is equipped with a taximeter.For each minute of waiting.$0.10 III \u2014 Taxicabs without taximeter local service For each mile travelled.$0.50 IV \u2014 Service outside limits In the case of a trip whose point of origin or final destination is situated 10 miles or more from the limits of the region or conglomeration to which the permit relates, or more than 10 miles from the conurbation of which the conglomeration to which the permit relates is part: (aj For a route or part of a route: (i) located to the east of a line drawn from the conglomeration of Alma to the conglomeration of West of Saguenay to the Region of St.Siméon-de-Charlevoix-East; and on the north shore of the St.Lawrence, to the east of said line: or (ii) located in the Counties of Témiscamingue and Abitibi or north of such Counties: $0.50 for each mile travelled.(6) For a route or part thereof not included in the territory described in paragraph a : $0.40 for each mile travelled. 7410 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 V - Baptêmes, mariages ou obsèques service local Dans le cadre du service local, au lieu des taux et tarifs sus-mentionnés pour le service fourni en vertu de permis de catégorie « ordinaire », dans le cas d'un baptême, d'un mariage ou d'obsèques, si le requérant en manifeste le désir lors de la réquisition: a) pour un baptême.$15.00 b) pour un mariage.17.00 c) pour des obsèques.18.00 VI \u2014 Bagages Dans le cas où le chauffeur de taxi transporte des bagages au début et à la fin d'une même course à un endroit plus éloigné qu'en Iwrdure immédiate du chemin, du consentement ou à la demande du requérant pour la majoration du piix de la course: $0.25 par bagage, à compter du deuxième bagage transporté par ce chauffeur de taxi.VII \u2014 Rémunération d'un chauffeur à la commission 40% des recettes brutes.Audience tenue à Montréal, le 19 novembre 1973.Audience tenue à Québec le 21 novembre 1973.Montréal, 29 novembre 1973.Et nous avons signé: Le lice-président.I,s-Piiilippe Bouchard, j.c.p.Le vice-président.Roland Bourret, j.c.p.Le commissaire.Paul-E.Dumas.Le commissaire.Mèdéric Gervais.Le commissaire.Germain .j.Beaudry.Le commissaire.55082-o Jacques M.Sauvé.II \u2014 Avis d'introduction de requête : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.Role M-735 604-DY & 279-DYV D-l CITY NATIONAL LEASING LIMITED c/o Mr.Karl Van Wert.23R0 Lucerne Rd suite 2-B, Montreal 305, P.Q.Bureau chef.1900, Victoria Park Avenue, Scarborough.Ontario.V \u2014 Christenings, weddings or funerals local service For local service, in the case of a christening, wedding or funeral, where the hirer so explicitly requests, the aforesaid rates and tariffs for service provided pursuant to a permit of the \"ordinary\" category, shall be replaced by the following: (a) for a christening.$15 00 0) for a wedding.17 00 (c) for a funeral.18.00 VI \u2014 Baggages In the case where the taxicab chauffeur carries baggage, at the beginning and at the end of the same trip, to a point located off the immediate roadside, upon the consent or request of the hirer, the increase in cost of the trip: shall be of $0 25 per piece of baggage, starting with the second piece of baggage carried by such a taxicab chauffeur.VII \u2014 Remuneration of a chauffeur on commission' 40% of the gross receipts.Hearing held in Montreal, on November 19, 1973.Hearing held in Québec, on November 21, 1973.Montreal, November 29.1973.And we have signed : Ls-Philippe Bouchard, j.p.c, Vice-President.Roland Bourret, j.p.c., Vice-President.Paul-E.Dumas.Commissioner.médéric CiERVAIS, Commissioner.Germain J.Beaudry, Commissioner.Jacques M.Sauvé, 55082-o Commissioner.II \u2014 Notice of submission of application : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Change of address: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize that the address of its place of business be changed to be as follows in the future: City National Leasing Limited.3500.Jean-Talon SIreet West, Montreal.P.Q.H3R 2E8.Head Office: 1900, Victoria Park Avenue, Scarborough, Ontario.Changement d'adresse: La partie requéranle demande a la Commission des transports du Québec d'autoriser le changement d'adresse de sa place d'affaire pour être à l'avenir comme suit: Citv National Leasing Limited.3500 ouest, rue Jean-Talon.Montréal, P.Q.H3R 2E8.Bureau chef: 1900.Victoria Park Avenue.Scarborough, Ontario. ! RAle M-736 1080-DY D-l MAISONNEUVE MERCURY SALES LTEE 505 Broadway.Montréal est, P.Q.Rôle M-737 1280-DY & 1003-DYV D-l BELLEVUE FORD SALES LTEE, 26, boul.D'Anjou.Chateauguay Centre.Cté de Chateauguay.P.Q.Rôle M-738 19626-V D-2 REA BROS.LTD., 4999 St.Catherine W., Montreal 215, Que.Rôle M-739 10762-V D-l ST-JOV1TE TRANSPORT ENRG., 651.Limoges, St-Jovite, Que.Rôle M-740 1949-V D-7 L.WOODS A SON TRANSPORT LTD., 5005, Avenue Irwin, LaSalle, Que.Rôle M-741 703-V D-2 C.LEBOEUF TRANSPORT INC., 43.rue Ste-Catherine.Beauharnois.Que.Changement d'adresse: La partie requérante demande h la Commission des transports du Québec de l'autoriser à changer l'adresse de sa place d'affaire pour être à l'avenir située à 12.455, Sherbrooke est, Pointe-aux-Trembles.Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location !\u2022 court terme (moins d'une année) pour automobiles de promenade restreint aux clients de vente et services.Service 2: Location ;\\ long terme (une année et plus) d'automobiles de promenade.Service 3: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce (familiales, station-wagons et camions) restreint aux clients de vente et de services.Service 4: Location a long terme (une année et plus) de véhicules de commerce (familiales, station-wagons et camions).Prolongation du délai: La requérante qui détient un permis dans lequel la clause c comporte une restriction se lisant comme suit: Le service autorisé par la clause r du présent permis devra être exploité avec un permis complémentaire devant être émis par l'Interstate Commerce Commission avant le 30 septembre 1973 au plus tard.Demande que le délai soit prolongé d'une année à partir du 30 septembre 1973 afin de pouvoir déposer le permis complémentaire auprès de la Commission.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis le service suivant : Le détenteur est autorisé h louer à long terme (4 ans), d'Associates Leasing (Canada) Limited, permis No 296 DYV, un (1) camion dont la description apparaît au contrat de location déposé t> la Commission.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande a la Commission d'ajouter aux clauses ».ii.jj.kk, nn, àhn et ut (clauses temporaires et expérimentales accordées le 14 février 1973).Modification of permit.The applicant requests that the following additional service be added to its permit : General trucking - long distance - radius - From all points located in the Counties of Abitibi-East, Abitibi-West, Témiscamingue and Rouyn-Noranda to all points located in the Municipality of James Bay, and return, for the transportation of general goods for one (1) shipper on any one trip.Additional right: When providing the service specified in the previous clause, the holder shall be authorized to utilize floats, temperature controlled and tank vehicles.Application for a special permit.The applicant requests from the Commission a special permit, valid for six (6) months or until final decision of the Commission, authorizing it to provide the following transportation: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Québec and Mont-Joli to Bic and Trois-Pistoles and intermediate points, as well as the localities authorized by clauses c, d, e and / of its permit, for the transportation, by temperature-controlled trucks, of perishable food products (frozen fruit and vegetables, fish, meat of all categories, salt products, eggs, poultry), on behalf of Provisions Adanac Inc., and Saguenay Fish Inc., of Québec, and return.Application for change of address The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to change the address of its place of business to 450 Lariviêre Street, Rouyn.Modification of permit.The applicant requests that the following additional service be included in its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route- From the Québec-Ontario border (Ports of entry: Chéminis and Judge), for furtherance to points in the counties of Témiscamingue, Abitibi-East.Abitibi-West and Rouyn-Noranda, for the carriage of meat, poultry and packing house products in temperature controlled vehicles from the point of origin in Ontario of New Liskeard.and return with refused and/or damaged goods only.Modification of permit (carrier).The applicant requests the following permit Authorization to utilize the haulaway transportation service of: André Grenier, haulaway operator, Pou-laries, County of Abitibi.23501-V.for the transportation of goods authorized by the following clauses of its permit No.6793-V.to wit: c to z inclusive; aa to zz inclusive; aaa to fff inclusive; yfftj, hhh and iii (temporary and experimental clauses granted on Feburary 14.1973.) 7420 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol 105, No.50 Rôle Q-463 23501-V D-l andre grenier, Poularies, Cté d'Abitibi.Rôle Q-4G4 19102-V D-l maritime-ontario freight lines limited, 200 Waverley Road, Dartmouth.N.S.Rôle Q-465 15-V D-6 transport d'anjou inc., 373, Térniscouata.CP.430, Rivière-du-Loup, Cté de Rivière-du-Loup.Procureur/Attorney : Me Jacques Langlois.Rôle Q-466 10-V D-8 guilbault transport inc., 220, rue Principale, St-Charles-des-Grondines.Cté de Portneuf.Procureurs/Attorneys: Paquette, Paquet te, Perreault & Rivet.Rôle Q-467 17G32-V D-l barbel transport inc., 1 - 1ère Rue, Gagnon, Cté de Saguenay.Mise en cause.Procureur/Attorney : Me Guy Pnrenteau.Demande de permis de voiturier-remor-queur.La partie requérante demande le permis suivant : Transport par remorquage - contrat -Autorisation de remorquer avec ses tracteurs dûment enregistrés des remorques et fardiers vides ou remplis pour le compte de: Brazeau Transport Inc.voiturier-roulier, 380, rue Burke, Rouyn.Cté du Témiscamingue.6793-V selon les clauses suivantes du permis No 6793-V, à savoir: c a z inclusivement ; aa à zz inclusivement; aaa à fff inclusivement ; 000.hhh et m (clauses temporaires et expérimentales accordées le 14 février 1973).Annulation de clause.Service de remorquage de véhicules de commerce.La partie requérante demande l'annulation de la clause de son permis autorisant le remorquage de ses véhicules de commerce par: Russel Floyd, 23121-V, voiturier-remor-queur, 379, Beaconsfield Crescent W., St.John, N.B.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service additionnel suivant: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - De Rivière-du-Loup au quai de Pointe-au-Pic en utilisant les services du ou des traversiez) de la compagnie Traverse Rivière-du-Loup - St-Siméon, pour le compte de F.F.Soucy Inc.Modification de permis.La partie requérante, détentrice d'un permis dont la clause x se lit: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - De Victoriaville et St-Hyacinthe à tous les endroits situés dans le comté électoral-provincial de Portneuf, pour le transport d'engrais chimique pour le compte de Canadian Industries Limited.demande que la susdite clause soit modifiée pour qu'elle se lise, à l'avenir, comme suit: Transport restreint-longue distance-route restreinte - contrat - De Victoriaville et St-Hyacinthe a tousles endroits situés dans les comtés électoraux-provinciaux de Champlain et Portneuf, pour le transport d'engrais chimique pour le compte de Canadian Industries Limited.Changement de contrôle dans la compagnie (vente d'actions).Québec Ontario Freightways Inc.a vendu a MM.Philippe Gauthier, Aurèle Landry, Herby Bérubé et Jean-Marc Harrison les actions qu'elle possède dans la mise en cause.On demande l'autorisation ft la Commission de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports.Distribution actuelle: Québec Ontario Freightways Inc.197 actions Gérard R.Huot 1 action Claude Richard 1 action Michel M.Lessard 1 action Application for a permît of haulaway operator.The applicant requests the following permit: Haulaway transportation - contract -Authorization to haul the empty or loaded trailers or floats, with his duly-registered tractors, on behald of: Brazeau Transport Inc., carrier, 380 Burke Street, Rouyn, County of Témiscamingue.6793-V according to the following clauses of permit No.6793-V, to wit: c to z inclusive; aa to zz inclusive; aaa to fff inclusive; 000, hhh and iii (temporary and experimental clauses granted on February 14, 1973).Cancellation of clause.Haulaway transportation service of commercial vehicles.The applicant requests the cancellation of the clause of its permit authorizing the haulage of its commercial vehicles by: Russel Floyd.23121-V, haulaway operator, 379 Beaconsfield Crescent W., St.John.N.B.Modification of permit.The applicant requests that the following additional service be added to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Rivière-du-Loup to the Pointe-au-Pic wharf while utilizing the services of the ferry (or ferries) of the Traverse Rivière-du-Loup - St.Simeon Company, on behalf of F.F.Soucy Inc.Modification of permit.The applicant, holder of a permit whose clause x reads: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Victoriaville and St.Hyacinthe to all points in the Provincial Electoral County of Portneuf.for the transportation of fertilizers on behalf of Canadian Industries Limited.The applicant requests that the aforesaid clause be modified to read henceforth as follows : Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Victoriaville and St.Hyacinthe to all points located in the Provincial Electoral Counties of Champlain and Portneuf, for the transportation of fertilizers on behalf of Canadian Industries Limited.Change of control in the company (sale of shares).Québec Ontario Freightways Inc.has sold to Messrs, Philippe Gauthier.Aurèle Landry, Herby Bérubé and Jean-Marc Harrison the shares it holds in the mise en cause.Authorization to do so is requested from the Commission, pursuant to the provisions of section 39 of the Transport Act.Present allotment: Québec Ontario Freightways Inc.197 shares Gérard R.Huot 1 shure Claude Richard 1 share Michel M.Lessard 1 share GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1973, 105' année, n° 50 7421 Hôle Q-468 2552-A D-l YVON SAUCIER, HO, rue Comtois, Louiseville, Ct6 Maskinongé, P.Q.Procureurs/Attorneys : Chartier, Ménard AGourdeau.Rôle Q-469 1047-DYV D-l LOCATION MARC LTEE.R.R.2, Victoriaville, Cté Arthabaaka.P.Q.Rôle Q-470 644-DYV D-l SEREX LEASING REG'D (Pierre Rivard opérant sous le nom de:) 3315, rue Normandie, Trois-Rivières.Par: M.Jean Roy, Syndic, ès-qualité.et ATRIUM LEASING INC., 10,272, houl.des Hêtres.Shawinigan, P.Q.Rôle Q-471 23324-V D-l LUCIEN TREMBLAY.St-Aubert, Cté l'Islet - tireur.6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC., 360, rue Burke, Rouyn, Cté Témiscamingue.Tiré.Procureur/Attorney : Me Benoit Groleau.Rôle Q-472 23530-V D-l GUY CHOUINARD.C.P.118, St-Aubert, Cté l'Islet.- tireur.BRAZEAU TRANSPORT INC.6793-V.380, rue Burke.Rouyn, Cté Témiscamingue - Tiré.Procureur/Attorney : Me Benoit Groleau.Nouvelle distribution: Philippe Gauthier 50 actions Aurèle Landry 50 actions Herby Bérubé 50 actions Jean-Marc Harrison 60 actions Nouvelle demande de permis.Classe de permis: Autobus.Service : 1.Transport d'étudiants le midi de la Polyvalente de Louiseville à la résidence des étudiants et retour.2.Transport local - à l'intérieur des municipalités de la ville et de la paroisse de Louiseville.Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser a donner les services de location de véhicules comme suit : Service 1 : Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison au sens du code de la route.Service 2: Location a court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison au sens du code de la route, h R.R.2, Victoriaville.P.Q.Transfert de permis et vente de services.Les requérants vendeurs qui sont détenteurs du permis de location de véhicules suivants: Service 1: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison (tracteurs, remorques).Service 2: Location ft court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison (tracteurs, remorques) à 3315.rue Normandie, Trois-Rivières, demande à la Commission des transports du Québec d'autoriser le transfert de leur permis et la vente de leurs services de location de véhicules h la compagnie requérante-acquéreur.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Lucien Tremblay h tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Brazeau Transport Inc.(6793-V).selon les clauses e à /// inclusivement, ainsi que selon les clauses du permis temporaire expérimental, émis en date du 14 février 1973, dudit permis No 6793-V.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Guy Choui-nard a tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Brazeau Transport Inc., (6793-V).selon les clauses c à ///inclusivement, ainsi que selon les clauses du permis temporaire expérimental, émis en date du 14 février 1973, dudit permis No 6793-V.New allotment : Philippe Gauthier 50 shares Aurèle Landry 60 shares Herby Bérubé 60 shares Jean-Marc Harrison 60 shares New application for a permit.Class of permit: Bus.Service 1: Transportation of students at noontime from the polyvalent school of Louiseville to the residences of the students and return.Service 2: Local transportation \u2014 within the limits of the Municipalities of the Town and Parish of Louiseville.New application: The applicant requests from the Québec Transport Commission the authorization to provide the following vehicle-leasing services: Service 1: Leasing on a long-term basis (one year or over) of commercial and delivery vehicles within the meaning of the Highway Code.Service 2: Leasing on a short-term basis (less than one year) of commercial and delivery vehicles within the meaning of the Highway Code, at R.R.2, Victoriaville.P.Q.Transfer of permit and sale of services: The applicant-vendors who hold the following vehicle-leasing permit : Service 1; Leasing of commercial and delivery vehicles (tractors, trailers) on a long-term basis (more than one year).Service 2: Leasing of commercial and delivery vehicles (tractor, trailers) on a short-term basis (less than one year), at 3315 Normandie Street.Trois-Rivières, requests from the Québec Transport Commission authorization to transfer their permit and to sell their vehicle-leasing services to the applicant-purchaser company.New application : Haulaway transportation - contract -¦ Request is made to authorize Lucien Tremblay to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc.(6793-V).according to clause c to /// inclusive and also according to the clauses of the temporary experimental permit issued on February 14, 1973, of said permit No.6793-V.New application Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Guy Choui-nard to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc., (6793-V), according to clauses c to /// inclusive and also according to the clauses of the temporary experimental permit issued on February' 14.1973.of said permit No.6793-V. 7422 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Rôle Q-515 D-l les membres de l'association nationale des camionneurs artisans inc.2750 Chemin Ste-Foy, P.Q.Les membres de l'Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.se sont adressés à la Commission des transports du Québec pour obtenir l'autorisation d'augmenter leurs taux ocmme suit: Exception aux item 12.46, 12.47, 12.49 du règlement 12 et suivant les pouvoirs conférés ù la Commission à 12.45, 12.48 dudit règlement.Augmentation générale du taux pour le camionnage en vrac: The members of the Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.have applied to the Québec Transport Commission for authorization to increase their rates as follows: Excluding sections 12.46, 12.47.12.49 of Regulation 12 and according to the powers conferred upon the Commission under sections 12.45, 12.48 of said Regulation.General increase in the bulk trucking rates: Taux Rates actuels demandés present requested La tonne Per ton Zone 1 Du Heu d'origine jusqu'au 1er mille / From the starting point uptothe $0.24 $0.28 first mile Par mille ou fraction de mille du 1er au 30e ' Per mile or fraction thereof 0.06 0.08 from the first to the 30th mile Par mille ou fraction de mille du 30e au 100e , Per mile or fraction there- 0.05 0.06 of from the 30th to the jOOth mile Par mille ou fraction de mille au-delà du 100e i Per mile or fraction 0.04 0.05 thereof beyond the 100th mile.Zone 2 Du lieu d'origine jusqu'au 1er mille / From the starting point up to the $0.24 0.28 first mile Par mille ou fraction de mille du 1er au 30e//Vr mile or fraction thereof 0.07.2 0.09 from the first to the 30th mile Par mille ou fraction de mille du 30e au 100e / Per mile or fraction there- 0.05 0.06 of from the 80th to the 100th mile Par mille ou fraction de mille au-delà du 100e/ Per mile or fraction 0.04 0.05 thereof beyond the JOOth mile.Taux horaires de déneigement / Hourly rates for snow removal: L'heure Per hour Aucun/ $ 9.00 Nil Pour tout véhicule dont la capacité de chargement est inférieur à 500 pieds cubes / For all vehicles whose loading capacity is less than 500 cubic feet Pour tout véhicule dont la capacité de chargement est supérieur à 500 Aucun 13.00 pieds cubes ou égal / For all vehicles whose loading capacity is equal Nil to or over 600 cubic feet.Rôle M-795 BT-e M D-1TF canadian transport tariff bureau ass'n 655.Dixon Road, Rexdale.Ontario.Augmentation de 12% au supplément No 39 du tarif de classe 10-E, B.T.Q.1500.Augmentation de 12% au supplément No 15 du tarif des marchandises No 15-K, B.T.Q.No 2805.Augmentation de 12% au supplément No 13 du tarif acier et fer No 32-G.B.T.Q.No 2909.Augmentation de 12% au supplément No 18 du tarif du papier No 40-G, B.T.Q.No 2910.Augmentation de 12% au supplément No 15 du tarif des marchandises exportées et importées No 45-M.B.T.Q.No 2808.Augmentation de 12% au supplément No 6 du tarif concurrentiel No 71-D, B.T.Q.No 2926.Augmentation de 12% nu supplément No 7 du tarif des contenants pour l'exportation et l'importation No 74-A, B.T.Q.No 3372.Augmentation de 12% au supplément No 3 du tarif pour l'équipement spécial No 210.B.T.Q.No 3275.Increase supplement No.39 to Class Tariff 10-E.T.B.Q.1500, reflecting a 12% increase.Increase supplement No.15 to Commodity Tariff No.16-K, T.B.Q.No.2805.reflecting a 12% increase.Increase supplement No.13 to Iron and Steel Tariff No.32-G.T.B.Q.No.2909 reflecting a 12% increase.Increase supplement No.18 to Paper Tariff No.40-G.T.B.Q.No.2910.reflecting a 12% increase.Increase supplement No.15 to Export and Import Commodity Tariff No.45-M, T.B.Q.No.2808 reflecting a 12% increase.Increase supplement No.6 to Competitive Tariff No.71-D, T.B.Q.No.2926 reflecting a 12% increase.Increase supplement No.7 to Import and Export Container Tariff No.74-A, T.B.Q.No.3372.reflecting a 12% increase.Increase supplement No.3 to Specialized Equipment Tariff No.210.T.B.O.No.3275.reflecting a 12% increase.S6083-O GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année, n\" 50 7423 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu Q-481 3535-A-P-l LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON, 1004, 3ième Avenue, Val d'Or, Québec.Q-479 23319-V-P-l GÉRARD ROY, Route 34.Botte 54, Victoriaville, (Arthabaska), Que.Q-480 21839-V-P-l BOURQUE, ERIC J., CP.96 Maria, (Bonaventure), P.Q.Q-506 1180-DY A 889-DYV P-l J.E.GENDRON AUTOMOBILES LTEE, 259, boul.Desjardin, Maniwaki (Gatineau), P.Q.Q-508 347G-A-P1 JACQUES LAVOIE, 69, Mgr Blanche.Sept-Iles, Cté Duplessis, P.Q.GAR 3E9 La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les 20 jours francs de la date de la présente publication.Pour corriger, dans le permis spécial délivré le 15 octobre 1973.les mots « le point connu sous le nom de LG 2 » par les mots: « de la piste L.G.2.» La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2.relativement au montant du cautionnement déposé par le requérant avec sa requête et non disposé dans la décision du 18 octobre 1973; Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours de la date de la présente publication.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2.relativement au montant du cautionnement fait par Eric J.Bourque avec sa requête, dans la cause 2184.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24, du règlement 2, pour décréter le remboursement du montant de $25.00, pour corriger la décision du 7 novembre 1973.qui a décrété le remboursement d'un montant de $50.00 du dépôt qui était de $75.00.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2.pour révoquer le permis qui n'est plus opéré, émis en faveur de J.Lavoie, 69, Mgr Blanche, Sept-Iles.Cté Duplessis, P.Q.dossier No 3476-A, lequel se lit comme suit: Classe de permis: Autobus.Service : Transport de passagers de la Ville de Sept-Iles à l'aéroport de ladite ville et retour.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Q-510 15812-V-P-l YVON TOUSIGNANT, Ste-Cécile-de-Lévrard, Cté de Nicolet.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2, pour reviser la décision du 5 novembre 1973 (QCR-317) quant au montant du dépôt remis à la partie requérante.15812-V Yvon Tousignant, Ste-Cécile-de-Lévrard, Cté de Nicolet.I \u2014 Notice \"proprio motu'1 by the Commission: The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of twenty (20) clear days following the date of this publication.To correct, in the special permit issued on October 15, 1973, the words \"the point known under the name of LG 2\" by the words: \"from trail L.G.2\".The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2 with regard to the amount of the deposit made by the applicant with his petition and not provided for in the decision of October 18.1973.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten days following the date ol this publication.The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2 with regard to the amount of the deposit made by Eric J.Bourque with his request, in case 2184.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.The Commission gives notice of its decision to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2, ordering the reimbursement of the sum of $25 thus amending the decision of November 7.1973, which ordered that, of the $75 deposit, the sum of $50 be reimbursed.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.revoking the permit, issued on behalf of J.Lavoie, 69 Mgr Blanche.Sept-Iles, County of Duplessis, P.Q.file No.3476-A.which permit is no longer being operated.Said permit reads as follows: Class of permit: Bus.Service: Transport of passengers from the City of Sept-Iles to the Airport of said City and return.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2, to revise the decision of November 5, 1973, (QCR-317) as regard the amount of the deposit handed over to the applicant.15812-V Yvon Tousignant, Ste.Cécile-de-Lévrard.County of Nicolet. 7424 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Q-511 23323-V-P-l adrien trudelle, 3225 houl.Ste-Anne, Giffard, Cté de Quéhec.GIE 3K7 Q-512 15957-V-P-l gerard nolin limitee, 150.De l'Eglise, St-Jean-Chrysostome, Cté de Levis.55082-O Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2.pour reviser la décision du 5 novembre 1973 (QCR-314) quant au montant du dépôt remis a la partie requérante.23323-V Adrien Trudelle.3225 boul.Ste-Anne, Giffard, Cté de Québec.G IE 3K7.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.La Commission donne avis qu'elle entend rendre une décision conformément aux dispositions de l'article 2.24 du règlement 2, pour révoquer les permis du voiturier-roulier connexes aux permis des voituriers-remor-queurs et vice-versa.15957-V Gérard Nolin Limitée.150, de l'Eglise, St-Jean-Chrysostome, Cté de Lévis, voiturier-roulier.23324-V Lucien Tremblav, St-Haubert, Cté de L'Islet.23334-V Yvon Gaudreault, Notre-Dame-du-Rosai-re, Cté de Montmagny.23344-V Placide Caron, St-Paul-de-la-Croix, Cté Rivière-du-Loup.23349-V André Fortin, C.P.158.St-Pamphile.Cté de L'Islet.23361-V Raynald Dionne.38, Normand, Amqui, Cté de Matapédia.23364-V Claude Sirois.400A -9ième.avenue La Po-catière.Cté de Kamouraska.voituriers-remorqueurs.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication.Anyone who wishes to be heard must make his intention kuown within a period often clear days following the date of this publica-(10) tion.The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2 to revise the decision of November 5, 1973 (QCR-314) as regards the amount of the deposit reimbursed to the applicant.23323-V Adrien Trudelle, 3225 Ste.Anne Boulevard, Giffard, County of Québec.GIE 3K7.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.The Commission gives notice of its intention to render a decision in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2, revoking the permits of the carrier that relate to the permits of the haulaway operators and vice versa.15957-V Gérard Nolin Limitée, 150 De l'Eglise.St.Jean-Chrysostome, County of Levis, carrier.23324-V Lucien Tremblay, St.Haubert.County of LTslet.23334-V Yvon Gaudreault.Notre-Dame-du-Rosai-re.County of Montmagny.23344-V Placide Caron, St.Paul-de-la-Croix, County of Rivière-du-Loup.23349-V André Fortin, Post Office.Box 158, St.Pamphile, County of L'Islet.23361-V Raynald Dionne, 38 Normand.Amqui.Countv of Matapédia.23364-V Claude Sirois, 400A - 9th Avenue, La Pocatière, County of Kamouraska, Haulaway operators.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication.Places d'affaires dans la Province Places of Business in the Province A.GLEDHILL & SONS INC.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « A.GI.EOHII.l.& SONS INC.», est 212.rue Bloomfield, Outremont, province de Québec.Iœs procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 55172-0 Pehreault & Rivet.GEORGES TATIGIAN Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de « GEORGES TATIGIAN » est 4425, rue Provost, Lacliine, Québec, telephone 634-4645.Les procureurs.Paquette, Paquette.55173-0 perreaui.t & RlVET, A.GLEDHILL & SONS INC.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"A.GLEDHILL & SONS INC.\" is 212 Hloom6eld St.Outremont, Province of Québec.55172-0 Paqi'ette, Paquette, Perreault & Rivet, Attorneys for the Company.GEORGES TATIGIAN Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"GEORGES TATIGIAN\" is 4425 Provost Street, Lachine, Québec, phone number: 634-4645 Paquette, Paquette, Perreaui.t & Rivet, 55173-0 Attorneys. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 décembre 1973, 105' année, n° 50 7425 ROBERT DAVID O'NEIL DELORME Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de ROBERT DAVID O'NEIL DELORME est a/s Jean-Guy Berner, 38, rue René, Rivière-Beaudette, Quénec.Téléphone: (514) 269-2721.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 55083-o Perreault & Rivet.ROBERT DAVID O'NEIL DELORME Notice is given that the address, for the Province of Quebec, of ROBERT DAVID O'NEIL DELORME.c/o Jean-Guy Berner, 38 René Street, Rivière-Beaudette, Québec.Phone number: (514) 269-2721.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 55083-o Attorneys for the Company.IVAN DENNING AND SONS ENTERPRISES LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « IVAN DENNING AND SONS ENTERPRISES LTD.», est: suite 1200, 129 rue St-Jacques, Montréal, Québec, H2Y 11,8.Les procureurs de la compagnie, McMaster, Meigiien, Minnion, Patch, 55084-o Cordeau, Hyndmax & Legge.IVAN DENNING AND SONS ENTERPRISES LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"IVAN DENNING AND SONS ENTERPRISES LTD.\", is: Suite 1200, 129 St-James Street, Montreal, Québec, H2Y 1L8.McMaster, Meighen, Minnion, Patch, Cordeau, Hyndman & Legge, 550S4-o Attorneys for the Company.CAPITAL COACH LINE Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « CAPITAL COACH LINE » est: 556, boul.St-René est, Gatineau Mills, Québec.Téléphone: (819) 771-1664.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 55186-0 Perreault & Rivet.CAPITAL COACH LINE Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"CAPITAL COACH LINE\" is: 556 St.René Blvd.East, Gatineau Mills, Québec.Telephone: (819) 771-1664.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 55186-0 Attorneys for the company.GAUTHD2R TRANSPORT ENRG.Avis est donné que la place d'affaires dans la province de Québec de M.Wilfrid Gauthier opérant sous le nom - GAUTHIER TRANSPORT ENRG.» est Avenue Duntar, Delson, province de Québec.Les procureurs de la requérante, 55187-0 Valois, Latour & Gilbert.GAUTHIER TRANSPORT ENRG.Notice is given that the place of business in the Province of Québec of Mr.Wilfrid Gauthier operating under the name of \"GAUTHIER TRANSPORT ENRG.\", is located on Duntar Avenue, Delson, Province of Québec.Valois, Latour & Gilbert, 55187 Attorneys for the applicant.MAC'S DELIVERY SERVICE Avis est donné que la place d'affaires dans la province de Québec de M.John J.McConville opérant sous le nom de « MACS DELIVERY SERVICE » est au 1665, Jacques Hertel, Montréal, province de Québec.Les procureurs de la requérante, 55188-0 Valois, Latour & Gilbert.MAC'S DELIVERY SERVICE Notice is given that the place of business in the Province of Québec of Mr.John J.McConville.operating under the name of \"MAC'S DELIVERY SERVICE\", is located at 1665 Jacques-Hertel, Montreal, Province of Québec.Valois, Latour & Gilbert, 55188 Attorneys for the applicant.T.E.QUINN TRUCK LINES LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « T.E.QUINN TRUCK LINES LTD.», permis No 19844 V est: 212, rue Bloomfield, Outreinont, province de Québec.Les procureurs de la compagnie.Paquette, Paquette, 55189-0 Perreault & Rivet.T.E.QUINN TRUCK LINES LTD.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"T.E.QUINN TRUCK LINES LTD.\", permit No.19844-V is: 212 Bloomfield St., Outre-mont.Province of Québec.Paquttte, Paquette, Pehreault & Rivet, 55189-0 Attorneys for the company. 7426 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, Xo.50 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE MAURICIENNE DE SHAWINIGAN (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 9 octobre 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE MAURICIENNE DE SHAWINIGAN » modifiant son territoire qui était « les paroisses St-Pierre et St-Bernard de Shawinigan - en celui de la « Cité de Shawinigan, Ville de Shawinigan-Sud.Ville de Grand'Mère.Paroisse Saint-Gérard-des-Lauren-tides.Village Baie-de-Shawinigan.Village Saint-Boniface-de-Shawinigan ».Québec, le 30 novembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 55179-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE NOTRE-DAME DES TROIS-RIVIERES (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 10 octobre 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE I)F, NOTRE-DAME DES TROIS-RIVIERES v' modifiant son territoire qui était « le quartier Notre-Dame et la paroisse Notre-Damc-dcs-Sept-Allégresses » en celui de « la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières-Ouest et la Cité du Cap-de-la-Madeleine ».Québec, le 30 novembre 1973.IjC sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 55180-e Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA SOCIETE D'ALUMINUM REYNOLDS (CANADA) LIMITEE Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 4 juin 1973 par \u2022 LA CAISSE D'ECONOMIE REYNOLDS ALUMINUM CREDIT UNION » changeant son nom en celui de « CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA SOCIETE D'ALUMINUM REYNOLDS (CANADA) LIMITEE » et modifiant son groupe qui était « Toute personne employée à la Reynolds Aluminum Company of Canada Limited » en celui de « les employés de la Société Reynolds Aluminum (Canada) Limitée et sa filiale Reynolds Aluminum Containers Limited ».Québec, le 23 novembre 1973./.e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).55183-n Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE MAURICIENNE DE SHAWINIGAN (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bvlaw adopted on October 9, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE MAURICIENNE DE SHAWINIGAN\", changing its territory which consisted of \"the Parishes of St.Pierre and St.Bernard de Shawinigan\", to tliat of \"City of Shawinigan, Town of Shawinigan-South, City of Grand'Mère, Parish of St.Gérard-des-Laurentides, Village of Baie-de-Shawinigan, Village of St.Boniface-de-Shawinigan\".Québec.November 30, 1973.Albeht Jessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 55179 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE NOTRE-DAME DES TROIS-RIVIERES (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the bvlaw adopted on Octobe, 10.1973.by \"LA CAISSE POPULAIRE DE NOTRE-DAME DES TROIS-RIVIERES\".changing its territory which was \"the Ward of Notre-Dame and the Parish of Notre-Dame-des-Sept-Allégresses\" to that of \"the City of Trois-Rivières.the Town of Trois-Rivières-West and the City of Cap-de-la-Madeleine\".Québec.November 30.1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 55180 Companies and Cooperatives.CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE LA SOCIETE D'ALUMINUM REYNOLDS (CANADA) LIMITEE Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the bvlaw adopted on June 4, 1973, bv \"LA CAISSE D'ECONOMIE REYNOLDS ALUMINUM CREDIT UNION\" changing its name to that of \"CAISSE D'ECONOMIE l>KS EMPLOYES DE I.A SOCIETE D'ALUMINUM REYNOLDS (CANADA) LIMITEE\" and modifying its group which consisted of \"all persons employed by the Reynolds Aluminum Company Limited\" to that of \"the employees of Société Reynolds Aluminum (Canada) Limitée and its subsidiary Reynolds Aluminum Containers Limited\".Québec.November 23, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minislcr of Financial Institutions, 55183 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7427 LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE JESUS, QUEBEC (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 27 février 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE JESUS.QUEBEC » modifiant son territoire qui était « la paroisse du Sacré-Coeur de Jésus, Québec » en celui de la « Ville de Québec ».Québec, le 30 novembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 55178-o Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES SERVICES HOSPITALIERS COMMUNS (MONTREAL) JOINT HOSPITAL SERVICES CREDIT UNION (MONTREAL) Avis de fusion de deux caisses d'épargne et de crédit Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la requête des caisses d'épargne et de crédit « ST.MARY'S HOSPITAL EMPLOYEES CREDIT UNION» et «CAISSE D'ÉCONOMIE DES EMPLOYES DE L'HOPITAL ROYAL VICTORIA \u2014 ROYAL VICTORIA HOSPITAL EMPLOYEES CREDIT UNION », datée du 30 mai 1973, demandant la confirmation de l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux caisses.Le nom de la caisse résultant de cette fusion est: « CAISSE D'ECONOMIE DES SERVICES HOSPITALIERS COMMUNS (MONTREAL)\u2014JOINT HOSPITAL SERVICES CREDIT UNION (MONTREAL) ».Le siège social de cette caisse est situé à Montréal dans le district électoral de Westmount.Le groupe dans lequel la caisse pourra recruter ses membres sera les employés des hôpitaux suivants: St.Mary's Hospital.Royal Victcria Hospital: Montreal Children's Hospital; Jewish General Hospital: The Montreal General Hospital The Lakeshore General Hospital Jewish Hospital of Hope Montreal Portestant Hospital Reddy Memorial Hospital The Allen Memorial Institute Montreal Neurological Hospital \u2014 Hôpital Neurologique de Montréal Grace d'Art Hospital Cette caisse sera affiliée à La Ligue des Caisses d'économie du Québec (1970) \u2014 The Québec Credit Union League (1970).Québec, le 30 novembre 1973.I^e sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), 55182-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE JESUS, QUEBEC (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on February 27, 1973.bv \"LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE JESUS, QUEBEC\", changing its territory which was \"the Parish of Sacré-Coeur de Jésus.Québec\" to that of \"the City of Québec\".Québec.November 30, 1973.Albert Jessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 55178 Companies and Cooperatives.CAISSE D'ECONOMIE DES SERVICES HOSPITALIERS COMMUNS (MONTREAL) JOINT HOSPITAL SERVICES CREDIT UNION (MONTREAL) Notice of amalgamation of two Savings and Credit Unions Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the request of the Savings and Credit Unions, \"ST.MARY'S HOSPITAL EMPLOYEES CREDIT UNION\" and \"CAISSE D'ECONOMIE DES EMPLOYES DE I'HOPITAL ROYAL VICTORIA \u2014 ROYAL VICTORIA HOSPITAL EMPLOYEES CREDIT UNION\", dated May 30, 1973, asking for confirmation of the deed of agreement authorizing the amalgamation of these two Unions.The name of the Union resulting from this amalgamation is: \"CAISSE D'ÉCONOMIE DES SERVICES HOSPITALIERS COMMUNS (MONTREAL)\u2014JOINT HOSPITAL SERVICES CREDIT UNION (MONTREAL)\".The head office of this Union is located in Montreal, in the electoral District of Westmount.The group from among which the Union may recruit its members shall be the employees of the following hospitals: St.Mary's Hospital Royal Victoria Hospital Montreal Children's Hospital Jewish General Hospital The Montreal General Hospital The Lakeshore General Hospital Jewish Hospital of Hope Montreal Protestant Hospital Reddy Memorial Hospital The Allen Memorial Institute Montreal Neurological Hospital \u2014 Hôpital Neurologique de Montréal Grace d'Art Hospital This Union shall be affiliated to La Ligue des Caisses d'économie du Québec 1970 \u2014The Québec Credit Union League (1970).Québec, November 30, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial 55182 Institutions.Companies and Cooperatives. 742S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PIIILIPPE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 28 août 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PHILIPPE » modifiant son territoire qui était « les paroisses de St-Pliilippe et Christ-Roi de Drummondvillc-Sud et de la Municipalité de St-Nicéphore » en celui de la « Ville de Drummond-ville-Sud, Cité de Drummondville.Grantham-Ouest.Saint-Nieéphore et Cantons Unis de Wendover and Simpson ».Québec, le 4 décembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopérai ires (par intérim), 55181-0 Albert Jessop.Avis divers Succession Noël Bélanger Acceptation sous bénéfice d'inventaire Avis est par les présentes donné, conformément à l'article 676 du Code civil de la province de Québec, que Monsieur Ludger Bélanger, Madame Rose-A.Lemieux, épouse de Ludger Bélanger, Monsieur Êmilien Bélanger.Monsieur Florian Bélanger, Monsieur Alfred Bélanger.Madame Albertine Bélanger, épouse de Y von Parent.Madame Marthe Bélanger, épouse de Paul-Émile Quirion.Monsieur Léonce Bélanger.Madame Ri-na Bélanger, épouse de Jean-Noël Lapointe, demeurant tous à Audet.comté de Frontenac.Madame Éliannc Bélanger, épouse de Jean-Claude Lachance.demeurant à Sherbrooke, province de Québec, Monsieur Raymond Bélanger, demeurant à Cooper Mills, Maine U.S.A.et Madame Anne-Emma Bélanger, épouse de Jean-Claude Galipeau, demeurant à Lac-Mégantic, comté de Frontenac, étant tous les héritiers de la succession de feu Noël Bélanger, en son vivant, journalier, demeurant à Montréal, province de Québec, décédé le treize février mil neuf cent soixante-dix.sans laisser de testament, ont accepte la succession dudit Noël Bélanger sous bénéfice d'inventaire, aux termes d'un acte exécuté devant Me Jean-Paul Normand, notaire, 5175, rue Frontenac, Lac-Mégantic, comté de Frontenac, province de Québec, le vingt-quatre novembre mil neuf cent soixante-treize, et enregistré à la division d'enregistrement de Montréal, sous le No 2478535.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant Me Jean-Paul Normand, notaire, et peut être consulté à ses bureaux à l'adresse ci-dessus.Après deux mois du présent avis, les bénéficiaires paieront les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Donné à Lac-Mégantic.comté de Frontenac, ce 4 décembre 1973.Le notaire.55154-0 Jean-Pail Normand.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PHILIPPE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, has approved the bvlaw adopted on August 28.1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-PHILIPPE\" changing its territory which was \"the Parishes of St.Philippe and Christ-Roi-dc-Drummondville-South and the Munic-icipality of St.Nicéphore\" to that of Town of Drum-mondvillc-South.City of Drummondville.Grantham-West, St.Nicéphore and the L'nited Townships of Wendover and Simpson\".Québec, December 4, 1973.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 55181 Companies and Cooperatives.Miscellaneous Notices Estate of Noël Bélanger Acceptance tinder benefit of inventory Notice is hereby given, according to article 676 of the Civil Code of the Province of Québec, that Mr.Ludger.Bélanger.Mrs; Rose A.Lemieux, wife of Ludger Bélanger, Mr.Emilien Bélanger, Mr.Florian Bélanger, Mr.Alfred Bélanger, Mrs.Albertine Bélanger, wife of Mr.Yvon Parent.Mrs.Marthe Bélanger, wife of Mr.Paul-Emile Quirion, Mr.Léonce Bélanger, Mrs.Rina Bélanger, wife of Mr.Jean-Noël Lapointe.all residing at Audet, County of Frontenac.Province of Québec.Mrs.Elianne Bélanger, wife of Mr.Jean-Claude Lachance.residing at Sherbrooke, Province of Québec, Mr.Raymond Bélanger, residing at Cooper Mills, Maine U.S.A.and Mrs.Anne-Emma Bélanger wife of Mr.Jean-Claude Galipeau, residing at Lac-Mégantic.County of Frontenac.Province of Québec, the only heirs of the late Noël Bélanger, in his lifeftime residing at Montreal, Province of Quebec, where he deceased on February 13th, 1970, without a will, accepted the estate of the said Noël Bélanger, under benefit of inventory, under the terms of a deed passed before Me Jean-Paul Normand, notary, practising at 5175 Frontenac Street, Lac-Méagntic, County of Frontenac, dated November 24.1973, copy of which is registered in Montreal division Registry Office under No.2478535.An inventory of property of the deceased was made before Me Jean-Paul Normand, notary and may be consulted at this office, at the address aforesaid: Two months after notice, the beneficiaries will pay the creditors as they come, according to law.Given at Lac-Mégantic.County of Frontenac, December 4, 1973.Jean-Paul Normand, 55154-0 Notary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n\" 50 7429 CLUB LES SANS PEUR INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 8c jour de novembre 1973, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CLUB LES SANS PEUR INC.», déjà constituée en corporation le ou vers le 1er décembre 1969, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $100,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Bonse-cours, district judiciaire de Bedford.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55080-o 730646 GAMACHE EXPLORATION & MINING CO.LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et en vertu également de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 6e jour de novembre 1973, à la corporation « GAMACHE EXPLORATION & MINING CO.LTD.» (No personal liability), étendant ses pouvoirs.Le directeur du service des compagnies, Pierke Desjardins.55080 11365-55 CLUB LES SANS PEUR INC.Notice is given that under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 8th day of November, 1973, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to incorporate as a corporation without share capital, the present members of \"CLUB LES SANS PEUR INC\", previously incorporated on or about the 1st December, 1969, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 8100,000.The bead office of the new corporation is in Bonse-cours, Judicial District of Bedford.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.55080 730646 GAMACHE EXPLORATION & MINING CO.LTD.Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act.supplementary letters patent, dated the 6th day of November 1973, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"GAMACHE EXPLORATION & MINING CO.LTD.\" (No personal liability), extending its powers.Pierre Desjahoins, Director of the Company Service.55080-o 11365-55 Paroisse de Sainte-Agnès-de-Donnacona et Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-des-Écureuils Avis est donné conformément à l'article 2 de la Loi des fabriques (Chap.76 des lois de la 1ère session de 1965) que Monsieur le Cardinal Maurice Roy.archevêque catholique romain de Québec, a, par un décret daté du 30 novembre 1973, modifié les limites des paroisses de Sainte-Agnès-dc-Donnacona et de Saint-Jean-Baptistc-des-Ecureuils de l'archidiocèsc de Québec.Québec, le 11 décembre 1973.L'Archevêque de Québec, 55208-o Maurice Cardinal Roy.Parish of Ste.Agnfcs-de-Donnacona and Parish of St.Jean-Baptiste-des-Écureuils Notice is given that pursuant to section 2 of the Fabrique Act (Statutes of 1965, 1st Session, Chapter 76), His Eminence Cardinal Maurice Roy, Roman Catholic Archbishop of Québec, has changed the limits of the Parishes of Ste.Agnès-de-Donnacona and St.Jean-Baptiste-des-Écureuils in the Archdiocese of Québec, by a decree dated November 30, 1973.Québec, December 11, 1973.Maurice Cardinal Roy, 55208 Archbishop of Québec.Paroisse de Saint-Maurice-de-Thetford-Mines et Paroisse Saint-Alphonse-de-Thetford-Mines Avis est donné conformément à l'article 2 de la Loi des fabriques (Chap.76 des lois de la 1ère session de 1965) que Monsieur le Cardinal Maurice Roy, archevêque catholique romain de Québec, a, par un décret daté du 8 décembre 1973, modifié les limites des paroisses de Saint-Maurice-dc-Thetford-Mines et de Saint-Alphonse dc-Thetford-Mines-de l'archidiocèsc de Québec.Québec, 11 décembre 1973.L'Archevêque de Québec.55209-o Maurice Cardinal Roy.Parish of St.Maurice-de-Thetford-Mines and Parish of St.Alphonse-de-Thctford-Mines Notice is given, in conformity with section 2 of the Fabrique Act (Statutes of 1965.1st Session, Chapter 76), that His Eminence Cardinal Maurice Roy, Roman Catholic Archbishop of Québec has modified the limits of the Parishes of St.Mauricc-de-ThetforJ-Mines and St.Alphoiise-dc-Thetford-Mines in the Archdiocese of Québec, by a decree dated December 8, 1973.Québec, December 11, 1973.Maurice Cahdinal Roy, 55209 Archbishop of Québec. 7 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED Avis est par les présentes donné que Maurice Babcux, de la Ville de Bouchcrville, District de Montréal, Province de Québec, s'adressera au Parlement du Canada, à sa présente session ou à la session suivante, afin de demander l'annulation d'un avis de dissolution relatif à la compagnie « ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE \u2014 ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED », donné le 17 juin 1968 et publié dans la Gazelle du Canada, le 22 juin 1968.Hull, ce 6e jour de septembre 1973.Les procureurs du pétitionnaire, 102 rue Principale, Martineau & Forget.Hull, P.Q.54810-47-4-o ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED Notice is by these presents given that Maurice Babeux.of the City of Boucherville, District of Montreal, Province of Québec, will address himself to the Parliament of Canada, at the present session or the following session, to request the annulation of a notice of dissolution in regard to the company \"ALLIANCE SECURITE ET INVESTIGATION LIMITEE \u2014 ALLIANCE SECURITY AND INVESTIGATION LIMITED, given the 17th day of June 1968, and published in the Canada Gazette, June 22nd, 1968.Hull, this 6th day of September 1973.Martineau & Forget, 102 Main Street, Attorneys for the petitioner.Hull, P.Q.54810-47-4-o Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications François Anatole Douillard Avis est donné que François Anatole Douillard, résidant et domicilié à Milan, district de St-François, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de François Arthur Douillard.Lac-Mégantic, le 14 novembre 1973.Le procureur du requérant, 54973-49-2-0 Guy Morin.Marie Solange Rioux Avis est donné que Marie Solange Rioux, résidant et domiciliée au rang 8 St-Adrien de Ham.district de St-François, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Marie Yuki Rioux.Lac-Mégantic.le 15 novembre, 1973.7,e procureur de la requérante, 55024-49-2-o Guy Morin.Maier Nagler Avis est par les présentes donné que « M.Maier Nagler.ingénieur, résidant et domicilié au 4625 Bourret.app.35, Montréal, dit district, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour un décret changeant son nom de M.Maier Nagler à celui de Martin Maier Nagler, ledit changement de nom devant aussi concerner son épouse Rita Paula Auer.de la même adresse.Montréal, ce 27 novembre 1973.Les avocats.Popovici & Pahizeau-Popovici.10 rue St-Jacques, suite 904, Montréal, P.Q.55058-49-2-o François Anatole Douillard Notice is given that François Anatole Douillard, residing and domiciled at Milan, district of St-François, will apply of the Lieutenant-Governor in Council to obtain a decree changing his name to François Arthur Douillard.Lac-Mégantic, November 14, 1973.Guy Morin, 54973-49-2-o Attorney for petitioner.Marie Solange Rioux Notice is given that Marie Solange Rioux.residing and domiciled at rang 8 St-Adrien de Ham.district of St-François, will apply of the Lieutenant-Governor in Council to obtain a decree changing his name to Marie Yuki Rioux.Lac-Mégantic, November 15th, 1973.Guy Morin, 55024-49-2-o Attorney for the Petitioner.Maier Nagler Notice is hereby given that Mr.Maier Nagler, engineer, residing and domiciled at 4625 Bourret, Apt.35, Montreal, said district, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mr.Maier Nagler to Mr.Martin Maier Nagler, said change of name will also benefit to his wife Rita Paula Auer, of the sami address.Montreal, November 27th.1973.Popovici & Parizeau-Popovici, Lawyers.10 St.James, room 904.Montreal, P.Q.55058-49-2-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7431 Raymond Alden Gazley Raymond Alden Gazley, journalier, domicilié et résidant au numéro 2224 rue Workman, app.7, dans la ville et le district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Raymond Alden Henderson.Montréal, le 15 octobre 1973.te procureur du requérant, 54974-49-2-o Ervin Orbach.Gerald O'Driscoll Avis est par les présentes donné que Gerald O'DriseoIl, présentement domicilié au 7030 de la rue D'Aragon, Montréal, province de Québec, présentera une demande au ministre de la justice de la province de Québec pour l'adoption d'un décret changeant son nom pour Gerald Dennis.Daté à Montréal, ce 5 octobre 1973.Les procureurs du requérant.54975-40-2-o Robert, Danser-eau & Barré.Raymond Alden Gazley Raymond Alden Gazley, day-labourer, domiciled and residing at 2224 Workman Street.Apt.7.in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to that of Raymond Alden Hendeison.Montreal, October 15, 1973.Ervin Orbacii.54974-49-2-0 Attorney for petitioner.Gerald O'Driscoll Notice is hereby given that Gerald O'Driscoll, residing at 7030 D'Aragon Street, Montreal, Province of Québec, shall apply to the Minister of Justice for an order changing his name to Gerald Dennis.Dated at Montreal.October 5, 1973.Robert, Dansereau & Barrk, 54975-49-2-0 Attorneys for applicant.Marie Nicole Suzanne Rochon Avis est donné que Marie Nicole Suzanne Rochon, domiciliée à 1405 boul.Labelle, Blainville, comté de Terrebonne, Que., transmettra au ministre de la justice une requête pour changer son nom en celui de Marie Nicole Suzanne Bonin.54976-49-2-0 Suzanne Rochon.Marie Nicole Suzanne Rochon Notice is given that Marie Nicole Suzanne Rochon, domiciled at 1405 Labelle Blvd., Blainville, Terrebonne County, Que., will apply to the Minister of Justice in order to have her name changed to Marie Nicole Suzanne Bonin.54976-49-2-0 Suzanne Rochon.Joseph Gaétan Jacques Grandmaison Avis est donné par les présentes que Joseph Gaétan Jacques Grandmaison.chauffeur, du 3407 est, rue Ontario, Montréal, Québec, entend presenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil demandant le changement de son nom en Joseph Gaétan Jacques De Grandmaison, conformément aux dispositions de la Loi du changement de nom.Ladite requête doit affecter sa femme.Dame Pierrette Chartrand, et ses enfants: Marie Huguette Muguette Carmen De Grandmaison, Joseph Marcel Yvon De Grandmaison, Marie Huguette Pierrette Sylvie De Grandmaison.Montréal, le 29 novembre 1973.Le procureur du requérant, 55088-50-2-o Me Harold C.Lehheu.Joseph Gaétan Jacques Grandmaison Notice is hereby given that Joseph Gaétan Jacques Grandmaison, chauffeur, of 3407 Ontario Street East, Montreal, Québec, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council requesting the change of his name to Joseph Gaétan Jacques De Grandmaison, pursuant to the provisions of the Change of Name Act.The said petition is to affect his wife, Dame Pierrette Chartrand and his children: Marie Huguette Muguelte Carmen De Grandmaison, Joseph Marcel Gaétan Yvon De Grandmaison.Marie Huguette Pierrette Sylvie De Grandmaison.' Montreal, November 29, 1973.Mtre Harold C.Leiirer, 55088-50-2-o Attorney for petitioner.Johann Rudolf Dossegger Avis est donné que Johann Rudolf Dôssegger.gérant, domicilié et résidant au 685.boulevard Graham, cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Rudolph Doseger.Montréal, le 29 novembre 1973.Les procureurs du requérant, 55122-50-2-o Behnieh & Boucher.Johann Rudolf Dossegger Notice is given that Johann Rudolf Dossegger, manager, domiciled and residing at 685, Graham Boulevard, City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Rudolph Doseger.Montreal.November 29th.1973.Bernier & Boucher, 55122-50-2-0 Attorneys for the applicant. 7432 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Miklos Buda Miklos Buda, résidant au 5512, avenue Monkland.Montréal, présentera une requête pour demander le changement de son nom patronymique à Toth.Montréal, le 3 juillet 1973.L'avocat du requérant.55065-49-2-o Paul Tardi.Miklos Buda Miklos Buda, residing at 5512 Monkland Avenue, Montreal, will apply for the change of his surname to Toth.Montreal, July 3rd.1973.Paul Tardi, 55065-49-2-o Attorney for the Petitioner.Marie Thérèse Bofnce Avis est par les présentes donné que Marie Thérèse Boffice, femme d'affaires, de la Cité de Montréal-Nord, district de Montréal, province de Québec, et demeurant au 12315 rue Lapierre, app.5, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille de Boffice à Alfieri.Les procureurs de la requérante.Robinson, Sheppard, Borenstein, 55086-50-2-o Shapiro & Flam.Marie Thérèse Bofnce Notice is given that Marie Thérèse Boffice, Businesswoman, of the City of Montreal-North, Province of Québec, therein residing at 12315 l.apierre Street, Apt.5, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorisation to change her surname from Boffice to Alfieri.Robinson.Sheppahd.Borenstein, Shapiro & Flam.55086-50-2-o Attorneys for petitioner.Myriam Boffice Avis est par les présentes donné que Myriam Boffice, étudiante, de la Cité de Montréal-Nord, district de Montréal, province de Québec, et demeurant au 12315 rue Lapierre.app.5, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille de Boffice à Alfieri.Les procureurs de la requérante, Robinson, Sheppard, Borenstein, 55087-50-2-o Shapiro & Flam.Myriam Boffice Notice is given that Myriam Boffice, Student, of the City of Montreal-North, Province of Québec, therein residing at 12315 Lapierre Street, Apt.5, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorization to changer her surname from Boffice to Alfieri.Robinson, Sheppahd, Bohenstein, Shapiro & Flam, 55087-50-2-o Attorneys for petitioner.Alfred Walczewski Nous donnons avis que Alfred Walczewski, étudiant, domicilié et résidant au numéro 3641, boulevard Saint-Laurent, ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Alfred Walsh ; ce changement de nom devant également bénéficier à l'épouse du requérant, née Janet Davidowicz, domiciliée au même endroit.Saint-Jean, le 29 novembre 1973.Les avocats du requérant.55089-50-2-o Cartier & Favreau.Alfred Walczewski Notice is hereby given that Alfred Walczewski, student, domiciled and residing at 3641 St.Lawrence Blvd., city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his name to Alfred Walsh: such change to benefit his wife, born Janet Davidowicz, domiciled end residing at the same place.Saint-Jean, this November 29, 1973.Cartier & Favreau, 55089-50-2-o Attorneys for petitioner.France Tremblay Avis est par les présentes donné que France Tremblay, résidant au 3,500 Aylmer, appartement 5, Montréal 130, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à François Tremblay.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Chicoutimi.le 21 novembre 1973.Les avocats du requérant.Roy, Vaillancourt 55149-50-2-o & Tremblay.France Tremblay Notice is hereby given that France Tremblay, residing at 3,500 Âylmer Street, apt.5, Montréal 130, district of Montreal, will petition the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his ne.me to François Tremblay.This change will not affect any person else than the applicant.Chicoutimi, November 21, 1973.Roy, Vaillancourt & Tremblay, 55149-50-2-o Attorneys for applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7433 CASTING MATERIALS WESTERN HEMISPHERE, INC Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 28 septembre 1973, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, monsieur Walter Kozelecki, du 450, avenue Racine, Dorval, a été nommé remplaçant de monsieur W.J.Bradley en tant qu'agent principal dans la province de « CASTING MATERIALS WESTERN HEMISPHERE, INC.», une compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Ix>i des compagnies étrangères.Avis est aussi donné qu'en vertu de la nouvelle procuration ci-dessus mentionnée, le siège social de ladite compagnie est établi au numéro 2088, avenue Chartier, Dorval.district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions, financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.55125 PA: 15-63 CASTING MATERIALS WESTERN HEMISPHERE, INC Notice is given that, by new power of attorney dated September 28, 1973, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.Walter Kozelecki, 450 Racine Avenue, Dorval, was appointed to replace Mr.W.J.Bradley as chief agent in the Province of \"CASTING MATERIALS WESTERN HEMISPHERE, INC.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head office of the said company is established at 2088 Chartier Avenue, Dorval, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.55125-0 PA: 15-63 Curatelle publique Succession Bertrand Lessard Succession de Lessard, Bertrand, en son vivant de 2e Rang, Mont St-Grégoire, cté Iberville, décédé le 21 décembre 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la I,oi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur Public du Québec, 9310.bout.St-Laurent.Montréal, Québec.H2N 1N6 55174-o Succession de Jean-Paul Ranger Succession de Ranger, Jean-Paul, en son vivant de Sherbrooke, décédé le 3 février 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 55085-o Public Curatorship Estate of Bertrand Lessard Estate of the late Lessard, Bertrand, in his lifetime of 2e Rang, Mont St.Grégoire, Co.Iberville, deaceased December 21, 1971.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address, men-tionned hereunder payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curatoh of Québec, 9310 St.Laurent Boulevard, Montreal, Québec.H2N 1N6 55174-0 Estate of Jean-Paul Ranger Estate of the late Ranger, Jean-Paul, in his lifetime of Sherbrooke, deceased February 3, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address mentionned hereunder, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Quebec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 55085-o Compagnies étrangères Extra-Provincial Companies Agent Agent 7434 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December IS, 1973, Vol.105, No.50 Succession Wilfrid Rhéaume Succession de Wilfrid Rhéaume, en son vivant de Lotbinière, décédé le 27 décembre 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi île la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public uu Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal.Que.H2N lX(i 55123-0 Estate of Wilfrid Rhéaume Estate of the late Wilfrid Rhéaume, in his lifetime of Lotbinière, deceased December 27, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address mentioned hereunder, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd.Montreal.Que.H2N 1N6 55123-0 Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Applications for Surrender of AGENCES BARON LTEE BARON AGENCIES LTD.Avis est donné que la compagnie « AGENCES BARON LTEE \u2014 BARON AGENCIES LTD.-demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 26 novembre 1973.Le procureur de la compagnie.David Litner, ch.Suite 2, Sommer Building 423, Mayor Street, Montréal, Canada.H3A 2K7 55106-o AGENCES BARON LTEE BARON AGENCIES LTD.Notice is given that \"AGENCES BARON LTEE \u2014 BARON AGENCIES LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.November 26, 1973.David Litner, q.c.Suite 2.Sommer Building, 423, Mayor Street, Montreal.Canada.H3A 2K7 Attorney for the company.55106-o ROGER BEDARD INC.Prenez avis que la compagnie « ROGER BEDARD INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Jean Brossard.notaire.Ville de St-Rémi.Comté de Napierville.55107-o ROGER BEDARD INC.Notice is given that \"ROGER BEDARD INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me Jean Brossard.notary.Attorney for the company.Town of St.Rémi.County of Napierville.55107 MARCHE USEE LTEE Prenez avis que la compagnie «MARCHE LISEE LTEE » compagnie incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Black Lake, dans le district de Mégantic, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Therford-Mincs.le 27 novembre 1973.Lea procureurs de la requérante, Cloutier.Landry.De Blois 8; 55115-0 Thi vierge, notaires.MARCHE LISEE LTEE Notice is hereby given that \"MARCHE LISEE LTEE\".corporation incorporated under Part I of the Companies Act and having its head office in the town of Black Lake, County of Mcgantic.will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Thetford-Mines, on the 27th of November.1973.Cloutier, Landry.De Blois & Tin vierge.Notaries.55115-o Attorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973.105' année, n\" 50 7435 YVES BOUCHARD INC.Prenez avis que la compagnie « YVES BOUCHARD INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 27 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.55108-o Bouchard.Cytrynbaum & YVex.YVES BOUCHARD INC.Notice is given that \"YVES BOUCHARD INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, November 27, 1973.Boucharu, Cytrynbaum & Wex, 55108 Attorneys for the company.ECOLE SAMOURAÏ DE KARATE ET JUDO INC.Prenez avis que ' ECOLE SAMOURAÏ DE KARATE ET JUDO INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 29 novembre 1973.Le procureur de la compagnie.André Deniers.10.Sl-Jacqucs.Montréal.H2Y 1L3 55109-o ECOLE SAMOURAÏ DE KARATE ET JUDO INC.Notice is hereby given that \"ECOLE SAMOURAÏ DE KARATE ET JUDO INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec to surrender its charter.Montreal.November 29th.1973.André Df.mehs.Attorney for the company.10.St.Jacques.Montreal.H2Y 1L3 55109-o ESAREN CONSTRUCTION CORPORATION Prenez avis que la compagnie « ESAREN CONSTRUCTION CORPORATION » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 29 novembre, 1973.Les procureurs de la compagnie.55110-o Greenblatt, Ginsberg & Associés.ESAREN CONSTRUCTION CORPORATION Take notice that \"ESAREN CONSTRUCTION CORPORATION\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Province of Québec, for leave to surrender its charter.Montreal.November 29th, 1973.Gheenblatt, Ginberg & Associates, 551 lO-o Attorneys for the Company.E.L.JULIEN LTEE La compagnie « E.L.JULIEN LTEE * donne avis qu'elle fera une demande à ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour qu'il accepte l'abandon de sa charte et en obtienne l'annulation, et fixe une date à compter de laquelle elle sera dissoute.Tracy, le 15 novembre 1973.Le notaire, 55111-0 Gilles Gougeox.E.L.JULIEN LTEE \"E.L.JULIEN LTEE\" hereby gives notice that petition will be made to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives, for the surrendering and cancellation of its charter and prays that a date l>e fixed for its dissolution.Tracy, November 15th, 1973.Gilles Gougeon, 55111-0 Notary.MAYFAIR BUILDINGS LTD.Avis est par les présentes donné que « MAYFAIR BUILDINGS LTD.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 31c jour d'août 1973.Les procureurs de la compagnie.Phillips & Vinebehc 1, Place Ville-Marie, Montréal 113.55116-o MAYFAIR BUILDINGS LTD.Notice is hereby given that \"MAYFAIR BUILDINGS LTD.\" incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 31st day of August, 1973.Phillips & Vineberg, Attorneys for the Company.1, Place Ville-Marie, Montreal 113.55116-o 7436 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol, 105, No.50 MAÇONNERIE DU ST-LAURENT LTEE Prenez avis que la compagnie « MAÇONNERIE DU ST-LAURENT LTEE » autrefois appelée « JULES TAILLON INC.» demandera au ministre des institutions financières, companies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Les notaires, DeMERS, CoRRIVEAU, 55113-0 Lemieux, Croft & Auger.MAÇONNERIE DU ST-LAURENT LTEE Notice is given that \"MAÇONNERIE DU ST-LAURENT LTEE\", formerly known as \"JULES TAILLON INC.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Demers.Cohriveau, Lemieux, Croft & Auger, 55113 Notaries.MARCHE D'ALIMENTATION M.C.M.LTEE Prenez avis que la compagnie « MARCHE D'ALIMENTATION M.C.M.LTEE », demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Trois-Rivières.le 30 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie, 55114-0 Martin & Blais, notaires.MARCHE D'ALIMENTATION M.C.M.LTEE Notice is hereby, given that \"MARCHE D'ALIMENTATION M.C.M.LTEE\".will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leaves to surrender its charter.Dated at Trois-Rivières, this 30th day of November, 1973.Martin & Blais, notaries.55114-o Attorneys of the Company.READ BUILDING SNACK BAR LTD.Avis est donné par les présentes que la compagnie \u2022READ BUILDING SNACK BAR LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 27e jour de novembre 1973.Les procureurs, 55117 Lazarus, Lehrer & Baer.READ BUILDING SNACK BAR LTD.Notice is hereby given that \"READ BUILDING SNACK BAR LTD.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter, under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 27th day of November, 1973.Lazarus.Leiirer & Baer, 55117-0 Attorneys.R ICI (MOUNT INVESTMENT CO.Avis est par les présentes donné que la compagnie « RICHMOUNT INVESTMENT CO.», corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies.Partie I.ayant son siège social dans la ville de Montréal, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies de la province.Montréal, Québec, ce 22e jour d'octobre 1973.Le secrétaire-trésorier.55118-0 Roger Roy.RICHMOUNT INVESTMENT CO.Notice is hereby given that \"RICHMOUNT INVESTMENT CO.\".a corporation constituted under Part I of the Companies Act.and having its head office in the City of Montreal.Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec.October 22nd.1973.Roger Roy.5511 S-o Secretary-Treasurer.JOSEPH SHAFFRAN INC.Prenez avis que la compagnie « JOSEPH SHAFFRAN INC.».demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 29 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.Greenulatt.Ginsberg 55120-o & Associés.JOSEPH SHAFFRAN INC.Take notice that \"JOSEPH SHAFFRAN INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Montreal.November 29th.1973.Greenblatt.Ginsberg & Associates.55120-o .Ittorneys for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105- année, n° 50 7437 R.O.LEVESQUE INC.Prenez avis que la compagnie « R.O.LEVESQUE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa chartre.Rimouski, le 23 novembre 1973.Le procureur de la compagnie, 55112-o Me Georges-Henri Dubé, notaire.R.O.LEVESQUE INC.Notice is hereby given that \"R.O.LEVESQUE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrenccr its charter.Dated at Rimouski.November 23rd 1973.Georges-Henri Dibé, Notary, 55112-0 Attorney for the Company.SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.Prenez avis que la compagnie « SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Ce 22e jour d'octobre 1973.Le notaire.Me Jean-Yves Simard.11025, Boul.Ste-Anne, Beaupré, Que.55119-o MARCEL BOURGEOIS INC Prenez avis que la compagnie « MARCEL BOURGEOIS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Daté ce 23 novembre 1973, à Saint-Jérôme.Le procureur de la compagnie.René Boismeni .ISO, rue de Martigny, Suite 200, St-Jérôme.Comté de Terrebonne.55126-0 SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.Take notice that \"SERVICE MECANIQUE DE QUEBEC INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.This 22nd day of October.1973.Me Jean-Yves Simard, Notary.11025, St.Anne Blvd., Beaupré, Que.55119-o MARCEL BOURGEOIS INC Notice is given that \"MARCEL BOURGEOIS INC.\" will apply the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at St.Jérôme, this 23th dav of November, 1973.René Boismenu, Attorney for the Company.180, de Martigny Street, Suite 200.St.Jérôme.County of Terrebonne.55126-0 GERARD BRIEN & FILS INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « GERARD BRIEN & FILS INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Sherbrooke, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté ce 3e jour de décembre 1973.La secrétaire, 55150-o Irenée Bégin.GERARD BRIEN & FILS INC.Notice is hereby given that \"GERARD BRIEN & FILS INC.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office at Sherbrooke, Que.will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated this 3rd day of December 1973.Irenée Begin, 55150-o Secretary.LITTFAM INVESTMENT CORPORATION Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « LITTFAM INVESTMENT CORPORATION » donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Montréal, P.Q-, ce 3e jour de décembre 1973.Le secrétaire.55152-0 J.K.Reynolds.LITTFAM INVESTMENT CORPORATION Under the provisions of the Companies Act, \"LITTFAM INVESTMENT CORPORATION\" hereby gives notice that is intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender the Charter of the Company, for cancellation of the Charter and for the dissolution of the Company.Montreal, P.Q., this 3rd day of December, 1973.J.K.Rey\"nolds, 55152-o Secretary. 7438 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 DISTRIBUTION VIMONT INC.Avis est donné que la compagnie ¦ DISTRIBUTION VIMONT INC.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 23 novembre 1973.Les procureurs de la compagnie.55151-0 Bisaillon, Leduc & Vallée.DISTRIBUTION VIMONT INC.Notice is given that \"DISTRIBUTION VIMONT INC.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, this 23rd of November 1973.BlSAILLON', I.EDL'C & VALLÉE, 55151-0 Attorneys for the Company.THEO PHENIX LTEE Prenez avis que la compagnie « THEO PHENIX LTEE \u2022 demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte Montreal, le 3 décembre 1973.Les procureurs de la compagnie.Dansereau, Daoust, 55153-0 Diceppe & Beaudhy.THEO PHENIX LTEE Notice is given that \"THEO PHENIX LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, December 3, 1973.Dansereai:, Daoust, Diceppe & Beaudry, 55153-0 Attorneys for the Company.CENTRE LOCAL DE SANTE ST-JACQUES INC.Avis est donné que la compagnie « CENTRE L0( 'Al.DE SANTE ST-JACQUES INC.» ayant son siège social en la ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 20 août 1973.Le procureur de la compagnie, 55158-0 Louis Duval.CENTRE LOCAL DE SANTE ST-JACQUES INC.Notice is given that \"CENTRE LOCAL DE SANTE ST-JACQUES INC.\" having its head office at Montreal, district of Montreal, will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, August 20, 1973.Louis Duval, 55158-0 Attorney for the Company.LES PLACEMENTS CONRAD BLANCHET INC.Prenez avis que « LES PLACEMENTS CONRAD BLANCHET IXC.», corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies ayant son siège social à Rock Forest, district de Saint-François, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Signé à Rock Forest, ce 18e jour de juin 1973.La secrétaire, 55159-0 Lin a Blanciiet.LES PLACEMENTS CONRAD BLANCHET INC.Notice is given that \"LES PLACEMENTS CONRAD BLANCHET INC.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in Rock Forest, District of Saint-François, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter in conformity with the provisions of the Companies Act.Signeil in Rock Forest, this 18th day of June, 1973.Lina Blanciiet, 55159 Secretary.EVERGREEN LAND DEVELOPMENT CO.Avis est donné que la compagnie « EVERGREEN\" LAND DEVEI.OPMEXT CO.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en le.ville de Montréal, province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la 1 .! des compagnies.Montréal, le 4 décembre 1973.Le procureur de la compagnie.55175 Leo D.I.avit.EVERGREEN LAND DEVELOPMENT CO.Notice is hereby given that \"EVERGREEN LAND DEVELOPMENT CO.\", a corporation incorporated under Companies Act and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its Charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, December 4, 1973.Leo D.Lavut, 55175-0 Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 197;!.105' année, n° 50 7439 BRVUN (QUEBEC) LIMITED Avis est donné par les présentes que « BRAUN (QUEBEC) LIMITED », une corporation constituée d'après la Loi des compagnies et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, fera une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 6e jour de décembre 1973.Les procureurs de la compagnie, 55193-0 Pascal, Cohen & Devine.BRAUN (QUEBEC) LIMITED Notice is hereby given that \"BRAUN (QUEBEC) LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act.and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 6th day of December 1973.Pascal.Cohen & Devine, 55193-0 Attorneys for the Company, ERNEST FAUBERT LTEE Prenez avis que la compagnie « ERNEST FAUBERT LTEE », une corporation ayant son siège social au numéro 115 de la rue Principale à St-Janvier.district de Terrebonne, ilemandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Saint-Jérôme, le 22 novembre 1973.Le procureur de la compagnie.55195-0 Me Camille L.de Mahtiony, ch.ERNEST FAUBERT LTEE Notice is given that \"ERNEST FAUBERT LTEE\", having its head office at 115 Principale Street, in St.Janvier, District of Terrebonne, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.St.Jérôme.November 22.1973.Me Camille L.de Marticny, q.c, 55195 Attorney for the Company.J.R.MVTHIEU LTEE Prenez avis que la compagnie « J.R.MATHIEU LTEE \u2022 demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.55197-0 Jacques Côté, notaire.J.R.MATHIEU LTEE Notice is given that \"J.R.MATHIEU LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Ctm-panies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jacques Côté, Notary, 55197-o Attorney for the company.PATRY INC.Avis est par les présentes donné que « PATRY INC.* corporation légalement constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pout obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies.Montréal, le 3 décembre 1973.Les procureurs de la compagnie.Guy, Vaillancourt, Bertrand, 55198-0 Bourgeois & Laurent.PATRY INC.Notice is hereby given that \"PATRY INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, December 3, 1973.Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent, 55198-0 Attorneys for the company.TOLEDO AUTO LEASING LTD.Avis est donné par les présentes que la compagnie « TOLEDO AUTO LEASING LTD.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 5e jour de décembre 1973.Les procureurs de la compagnie, Duquet, MacKay, YVeldon, 55199-0 Bhonstetter & Tiiivierge.TOLEDO AUTO LEASING LTD.Notice is hereby given that \"TOLEDO AUTO LEASING LTD.\".incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its Charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 5th day of December, 1973.Duquet, MacKay.Weldox, Bronstetter & Thivierge, 55199-0 Attorneys for the company. 7440 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 9173, Vol.105, So.50 COMMERCIAL PROPERTY DEVELOPMENTS INC.Avis est par les présentes donné que « COMMERCIAL PROPERTY DEVELOPMENTS INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 3e jour de décembre 1973.La secrétaire, 55194-0 Mme D.Hampshire.COMMERCIAL PROPERTY DEVELOPMENTS INC.Notice is hereby given that \"COMMERCIAL PROPERTY DEVELOPMENTS INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 3rd day of December, 1973.Mrs.D.Hampshire, 55194-0 Secretary.GIT.-MAR EXCAVATION LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « GUE-MAR EXCAVATION LTEE », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Napierville, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de ladite Loi des compagnies.Donné à Napierville.ce 20e jour de novembre 1973.(Sceau) 55196-0 Le secrétaire, Georges Martin.GUE-MAR EXCAVATION LTEE Notice is hereby given that \"GUE-MAR EXCAVATION LTEE\".a corporation incorporated under Part I of the Companies Act, and having its head office in the City of Napierville, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the said Companies Act.Given at Napierville.this 20th day of November, 1973.(Seal) Georges Martin, 55196-0 Secretary.Divers Compagnies Miscellaneous Companies LA SOCIETE J.B.MARTIN LIMITEE J.B.MARTIN COMPANY LIMITED «LA SOCIETE J.B.MARTIN LIMITEE \u2014J.B.MARTIN COMPANY LIMITED > donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 6.Le secrétaire, Ivan Sabourin.55090-o 2377-34 NEVEU & NEVEU LTEE La compagnie « NEVEU & NEVEU LTEE i donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Jean-Yves Neveu.55131-0 4600-69 SPANCRETE, LIMITED La compagnie « SPANCRETE, LIMITED donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire, R.L.Hébert, c.a.55134-0 14841-62 LA SOCIETE J.B.MARTIN LIMITEE J.B.MARTIN COMPANY LIMITED Notice is given that \"LA SOCIETE J.B.MARTIN-LIMITEE \u2014 J.B.MARTIN COMPANY LIMITED\" has changed the number of its directors from 7 to 6.Ivan Sabourin, Secretary.55090 2377-34 NEVEU & NEVEU LTEE Notice is given that \"NEVEU & NEVEU LTEE\" has increased the number of its directors trom 3 to 4.55131 Jean-Yves Neveu, Secretary.4600-69 SPANCRETE, LIMITED Notice is given that \"SPANCRETE.LIMITED\" has increased the number of its directors from 3 to 5.55134 R.L.hébert.c.a., Secretary.14841-62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n\" 50 7441 ALLPAK (QUEBEC) LIMITED ALLPAK (QUEBEC) LIMITED ALLPAK (QUEBEC) LIMITEE ALLPAK (QUEBEC) LIMITEE La compagnie « ALLPAK (QUEBEC) LIMITED \u2014 ALLPAK (QUEBEC) LIMITEE » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, R.B.Willis.55127 1879-67 Notice is given that \"ALLPAK (QUEBEC) LIMITED \u2014 ALLPAK (QUEBEC) LIMITEE\" has changed the number of its directors from 3 to 4.R.B.Willis, Secretary-treasurer.55127-0 1879-67 CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC La corporation « CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 6.Le secrétaire, Pierre Mercier.55128-0 732664 CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC Notice is given that \"CAMP FAMILIAL BLEU ET BLANC INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 6.Pierre Mercier, Secretary.55128-0 732664 LIGUES DU HOCKEY MINEUR DE N.D.G.INC N.D.G.MINOR HOCKEY LEAGUES INC La corporation « LIGUES DU HOCKEY MINEUR DE N.D.G.INC.\u2014 N.D.G.MINOR HOCKEY LEAGUES INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 5.Le secrétaire.Lack B.Wallace.55129-q 730527 LIGUES DU HOCKEY MINEUR DE N.D.G.INC N.D.G.MINOR HOCKEY LEAGUES INC Notice is given that \"LIGUES DU HOCKEY MINEUR DE N.D.G.INC.\u2014 N.D.G.MINOR HOCKEY LEAGUES INC.\" has increased the number of its directors from 4 to 5.Lack B.Wallace, Secretary.55129 730527 GAR-LAN LEASING (QUEBEC) LTD .GAR-LAN LEASING (QUEBEC) LTD LOCATION GAR-LAN (QUEBEC) LTEE LOCATION GAR-LAN (QUEBEC) LTEE La compagnie « GAR-LAN LEASING (QUEBEC) LTD.\u2014 LOCATION GAR-LAN (QUEBEC) LTEE » donne avis qu'elle a augmenté de 4 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Alan Rimer.55130 726376 Notice is given that \"GAR-LAN LEASING (QUEBEC) LTD.\u2014 LOCATION GAR-LAN (QUEBEC) LTEE\" has changed the number of its directors from 4 to 5.Alan Rimer, Secretary.55130-o 726376 POULIOT, GUERARD & ASSOCIES INC.POULIOT, GUERARD & ASSOCIATES INC.La compagnie « POULIOT, GUERARD & ASSOCIES INC.\u2014 POULIOT, GUERARD & ASSOCIATES INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 9.Le secrétaire, Maurice D.Godbout.55132-o 13773-62 POULIOT, GUERARD & ASSOCIES INC.POULIOT, GUERARD & ASSOCIATES INC.Notice is given that \"POULIOT, GUERARD & ASSOCIES INC.\u2014 POULIOT.GUERARD & ASSOCIATES INC.\" has increased the number of its directors from 7 to 9.Maurice D.Godbout, Secretary.55132 13773-62 SOCIETE D'ADMINISTRATION DERO INC.La «SOCIETE D'ADMINISTRATION DERO INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire, Jean Marier.55133-0 2699-67 SOCIETE D'ADMINISTRATION DERO INC.Notice is given that \"SOCIETE D'ADMINISTRATION DERO INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Jean Marier, Secretary.55133-0 2699-67 7442 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973, Vol.105.No.50 CANEXCO INC.I .a compagnie « CANEXCO INC.\u2022 donne avis qu'elle a change le nombre He ses administrateurs de 7 à 3.Le sécrétai.-e.Raymond Blais.55190-o ss.Vt'.l CANEXCO INC.Notice il given that \"CANEXCO INC.\" has changed the number of its directors from 7 to 3.55190 Raymond Blais, Secretary.885-64 Sièges sociaux Head Offices BRASSERIE LA GARGOTE INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « BRASSERIE LA GARGOTE INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 septembre 1973 a son siège social au numéro 115, boul.des Laurentides.Suite 202.(Pont-Viau) Ville de Laval, province de Québec.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à I.aval.ce sixième jour de novembre mil neuf cent soixante-treize (1973).Le président.55091-o Guy Dupuis.LES CINEASTES ASSOCIES INC.La compagnie « LES CINEASTES ASSOCIES INC.» donne avis que son siège social est dorénavant situé au 3fil Place Royale, Montréal 125, Québec.Le président.Claude Bureau.55092-o 662-65 DOMAINE NEVEU INC.Avis est donné que la compagnie 4 DOMAINE NEVEU INC.» a été constituée en corporation dans la prov'nce de Quéliec.par lettres patentes enregistrée le 16 octobre 1973.Sa principale place d'affaires dans la province de Québec est à Stc-Brigidc.comté d'Iberville.rang de la Rivière ouest.Le procureur de la compagnie.55094-o Claude Gratton.EIFFEL CONSTRUCTION INC.La compagnie «EIFFEL CONSTRUCTION INC., constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 24 janvier 1964, donne avis par les présentes qu'elle a transféré son siège social du 5595.avenue Clanranald.en les ville et district de Montréal, au 0X56.chemin Haywood, en les ville et district de Montréal, province de Québec.Montréal, ce 21e jour de novembre 1973.Le secrétaire.55095 Paul Orlan.BRASSERIE LA GARGOTE INC.Notice is hereby given that \"BRASSERIE LA GARGOTE INC.\".incorporated by letters patent dated September '-'.\">.1973.has established il- head office at 115 des Laurentides Boulevard.Suite 202.(Pont-Viau).City of Laval.Province of Québec.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in Laval, this sixth day of November one thousand nine hundred seventy-three (1973).Guy Dupuis, 55091 President.LES CINEASTES ASSOCIES INC.Notice is hereby given that the head office of the company \"LES CINEASTES ASSOCIES INC.\" is now situated at 361 Place Royale.Montreal 125.Québec.Claude Bureau, President.55092-o 662-65 DOMAINE NEVEU INC.Notice is given that \"DOMAINE NEVEU INC.\" was incorporated in the Province of Québec by letters patent registered on October 16.1973.Its principal place of business in the Province of Quclicc is in Ste.Brigide.County of Iberville, La Rivière ouest Range.Claude Gratton.55094 Attorney for the Company.EIFFEL CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"EIFFEL CONSTRUCTION INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated January 24th.1964.has moved its head office from 5595 Clanranald Avenue, in the City and District of Montreal, to 6K56 Haywood Road, in the City and District of Montreal.Province of Quél>cc.Montreal, this 21st day of November.1973.Paul Orlan, 55095-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7443 LES COURTIERS EN IMMEUBLES DANIERE INC.Avis est donné que la compagnie « LES COURTIERS EN IMMEUBLE DANIERE INC.».constituée en corporation par lettres patentes en date du 24 avril 1973, et ayant son siège social à Val St-Michel, a établi son bureau au numéro 49, 23ième Rue, Val St-Michel, Que.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 30e jour d'avril 1973.Le président, 55093-o Jean-Marc Gagné.LES COURTIERS EN IMMEUBLES DANIERE INC.Notice is given that \"LES COURTIERS EN IMMEUBLES DANIERE INC.\".incorporated by letters patent dated April 24.1973.and having its head office in Val St.Michel, has established its office at 49 - 23rd Street, Val St.Michel, Que.From the date of this notice, said office shall be considered by the Company as its head office.Given in Québec, this 30th day of April, 1973.Jean-Marc Gagné, 55039 President.GOULD AUTO SUPPLY CO.Avis est donné que la compagnie « GOULD AUTO SUPPLY CO.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies du Québec le 20 avril 1953 et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 6460, boulevard St-Laurent, l'a transporté au numéro 631_4, rue de Lanaudière à Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 29 novembre 1973.Le secrétaire, 55096-o Serge Péladeau.GOULD AUTO SUPPLY CO.Notice is given that \"GOULD AUTO SUPPLY CO.\", incorporated under the Companies Act on April 20.1953 and having its head office in the City of Montreal, where its office was located until the present day at 6460 St.Laurent Boulevard, has transferred said office to 6314 de I-anaudière Street, Montreal.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Montreal, on November 29,1973.Serge Péladeau, 55096 Secretary.LEMEGO CONSTRUCTION LTD.Avis est donné que la compagnie « LEMEGO CONSTRUCTION LTD.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de Loi des compagnies en date du 16 novembre 1973, et ayant son siège social dans la Ville de Montréal, a établi son bureau au numéro Suite 930, 1 Place Ville Marie.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 28e jour de novembre 1973.(Sceau) Le président, 55098-o Sergio Balsinde.LEMEGO CONSTRUCTION LTD.Notice is hereby given that \"LEMEGO CONSTRUCTION LTD.\".incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act on the 16th day of November, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at Suite 930, 1 Place Ville Marie.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 28th day of November, 1973.(Seal) Sergio Balsinde, 55098-0 President.LES PLACEMENTS GRAND CALUMET INC.Avis est donné que la compagnie « LES PLACEMENTS GRAND CALUMET INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 septembre 1973 et ayant son siège social en la ville de Sept-îles, a établi son bureau au numéro 594 rue Humphrey, Sept-Iles.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Sept-Iles, ce 21e jour de novembre 1973.Le président, 55102-o Paul M.Roy.LES PLACEMENTS GRAND CALUMET INC.Notice is herebv given that the \"LES PLACEMENTS GRAND' CALUMET INC.\", company incorporated by letters patent on September 25th, 1973.and having its head office in Sept-Iles, has established its office at No.594 Humphrey Street, Sept-Iles.From and after the date cf this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Sept-îles, this 21st day of November, 1973.Paul M.Roy, 55102-o President. 7444 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE Avis est donné que la compagnie « LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE » a transféré son siège social du numéro 235 est, boulevard Dorchester, Montréal à 1.Place Ville Marie, suite 1734, Montréal, province de Québec.Le secrétaire, GÉRARD hogvk.55097-o 71-6387 MIRABEL AUTOMOBILE LTEE Avis est donné que la compagnie « MIRABEL AUTOMOBILE LTEE » a été constituée en corporation dans la province de Québec par lettres patentes enregistrées le 5 octobre 1973.Sa principale place d'affaires dans la province de Québec est à 144 boulevard Arthur Sauvé, St-Eustache.Le procureur de la compagnie.55099-O Me Claude Gratton, notaire.LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE Notice is given that \"LES INVESTISSEMENTS M.L.R.S.LTEE\" has transferred its head office from 235 Dorchester Boulevard East, Montreal, to 1 Place Ville Marie, Suite 1734, Montreal, Province of Québec.gérard hogue, Secretary.55097 71-6387 MIRABEL AUTOMOBILE LTEE Notice is given that \"MIRABEL AUTOMOBILE LTEE\" was incorporated in the Province of Québec by letters patent registered on October 5, 1973.Its principal place of business in the Province of Québec is located at 144 Arthur Sauvé Boulevard, St.Eustache.Me Claude Grattox, notary, 55099 Attorney for the company.NAM RON REALTY CORP.Avis est donné que la compagnie « NAMRON REALTY CORP.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la l,oi des compagnies, a transféré son siège social du 2450, rue Holt à Montréal (Québec) au 4784, avenue Van Home, suite 105, à Montréal (Québec).Donné à Montréal, le 12 novembre 1973.La secrétaire, 55100 Judith Sternthall.NAM RON REALTY CORP.Notice is hereby given that \"NAMRON REALTY CORP.\", incorporated under Part I of the Companies Act, has moved its head office from 2450 Holt Street, Montreal, Québec, to 4784 Van Home Avenue, Suite 105, Montreal, Québec.Dated at Montreal, November 12th, 1973.Judith Sternthall, 55100-o Secretary.LES PLACEMENTS MONGA INC.Avis est donné que la compagnie « LES PLACEMENTS MONGA INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 21 septembre 1973 et ayant son siège social à Val St-Michel, a établi son bureau au 49, 23e rue.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Québec, ce 24e jour de septembre 1973.Le président, 55103-o Jean-Marc Gagné.LES PLACEMENTS MONGA INC.Notice is given that \"LES PLACEMENTS MONGA INC.\", incorporated by letters patent dated September 21, 1973, and having its head office in Val St.Michel, has established its office at 49 - 23rd Street.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in Québec, this 24th day of September, 1973.Jean-Marc Gagne, 55103 President.ST.MICHEL REALTIES INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie 'ST.MICHEL REALITES INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, a transféré son siège social du 2450, rue Holt à Montréal (Québec), au 4784, avenue Van Home, bureau 105, à Montréal (Québec).Daté à Montréal, le 12 novembre 1973.Le secrétaire, 55104 Alan Zavalkoff.ST.MICHEL REALTIES INC.Notice is hereby given that \"ST.MICHEL REALTIES INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act, has moved its head office from 2450 Holt Street, Montreal.(Québec), to 4784 Van Heme Ave., 105, Montreal.(Québec).Dated at Montreal, November 12th, 1973.Alan Zavalkoff, 55104-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.15 décembre 1073.105' année, u° 50 7445 LES PLACEMENTS CAR ISA INC.Avis est donné que la compagnie « LES PLACEMENTS CARISA INC.» a transféré son siège social du numéro 7 rue Drapeau, Place Bonaventure, au numéro 20 rue Elgin.Place Honaventure, Montréal.La secrétaire, Gisèle Dupuis.5510l-o 72-9622 LES PLACEMENTS CARISA INC.Notice is given that \"LES PLACEMENTS CARISA INC.\" has transferred its head office from 7 Drapeau Street.Place Bonaventure, to 20 Elgin Street, Place Bonaventure, Montreal.Gisèle Dupuis, Secretary.55101 72-9622 ST.MICHEL REALTIES (MONTREAL) LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « ST.MICHEL REALTIES (MONTREAL) LTD.>.constituée en corporation en vertu de la première partie de la Im des compagnies, a transféré son siège social du 2450, rue Holt à Montréal, (Québec), au 4784, avenue Van Home, suite 105.à Montréal.(Quéliec).Donné à Montréal, le 12 novembre 1973.Le secrétaire, 55105 gerald Zavalkoff.ST.MICHEL REALTIES (MONTREAL) LTD.Notice is herebv given that \"ST.MICHEL REALTIES MONTREAL) LTD.\", incorporated under Pari I of the Companies Act, has moved its head office from 2450 Holt Street.Montreal.(Québec), to 4784 Van Home Avenue, Suite 105, Montreal, (Québec), Dated at Montreal, November 12th, 1973.Gerald Zavalkoff.55105-o Secretary.RESTAURANT CHATEAU WONG INC CHATEAU WONG RESTAURANT INC Avis est par les présentes donné que la compagnie « RESTAURANT CHATEAU WONG INC.\u2014 CHA-TEAU WONG RESTAURANT INC.\u2022 constituée en corporation par lettres patentes en date du 28e jour de septembre 1973.et ayant son siège social à Ville l,aSalle, a établi son bureau au 1497, rue Dollard.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 26e jour de novembre 1973.55136 Donald Woni;.RESTAURANT CHATEAU WONG INC CHATEAU WONG RESTAURANT INC Notice is hereby given that the \"RESTAURANT CHATEAU WONG INC.\u2014 CHATEAU WONG RESTAURANT INC.\" company incorporated by letters patent, on the 28th day of September 1973.and having its head office in City of LaSalle.has established its office at No.1497.Dollard Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal\", this 26th day of November 1973.55136-0 Donald Wong.GESTION BOUGAINVILLE LTEE La compagnie «GESTION BOUGAINVILLE LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 585.avenue des Cèdres, Shawinigan, au numéro 90, rue Des Cescrnes.Trois-Rivières.Iai secrétaire.Hélène Brocard.55I38-0 734610 KAY, MARTEL INC Avis est donné que la compagnie « KAY'.MARTEL INC.°, est constituée en corporation par lettres patentes en date du 2 avril 1973, a son bureau principal à L'Assomption, au numéro 341 de la rue Point-du-.Iour Nord.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à L'Assomption, ce 12 novembre 1973.Le procureur de la compagnie.bertrand Allah d.notaire.55140-O 731499 GESTION BOUGAINVILLE LTEE Notice is given that \"GESTION BOUGAINVILLE LTEE\" has transferred its head office from 585 des Cèdres Avenue, Shawinigan, to 90 Des Casernes Street, Trois-Rivières.Hélène Broiard.Secretary.55138-0 734610 KAY, MARTEL INC Notice is given that \"KAY.MARTEL INC.\", is incorporated by letters patent dated April 2, 1973, and that its head office is located at 341 lYint-du-Jour-Nord Street, in l'Assomption.From the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in l'Assomption, this twelfth day of Novembei one thousand nine hundred seventy-three.Bertrand Allard.Notary, Attorney for the Company.55140 731499 7446 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 LE CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE BOUCIIERVILLE INC La compagnie « LE CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE BOUCHERVILLE INC.» donne avis qu'elle a change son siège social de Montréal, au numéro 99, Place Charles Lemoyne, suite 2902, Longueuil.La secrétaire, Anne-Marie Trahan.55137-0 737522 GRANTON PRODUCTS LTD La compagnie « GRANTON PRODUCTS LTD.> donne avis qu'elle a transféré son siège social du 1390, rue Sherbrooke ouest, Montréal au 11.Place Parkman, Westmount.La secrétaire.Patricia Anne Mason.55139 2658-69 LE CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE BOUCHERVILLE INC Notice is given that \"LE CLUB DE HOCKEY LES SEIGNEURS DE BOUCHERVILLE INC.\" has transferred its head office from Montreal, to 99 Charles Lemoyne Place, Suite 2902, Longueuil.Anne-Marie Thahan, Secretary.55137 737522 GRANTON PRODUCTS LTD Notice is given that \"GRANTON PRODUCTS LTD.\" has transferred its head office from 1390 Sherbrooke Street West, Montreal, to 11 Parkman Place, Westmount.Patricia Anne Mason, Secretary.55139-0 2658-69 M AISONNEUVE AUTOMOBILES INC Avis est donné que la compagnie « MAISONNEUYE AUTOMOBILES INC.», constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes accordées en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 19 novembre 1971, et ayant son bureau principal dans la cité de Québec, district de Québec, province de Québec, a établi son bureau à 136 Maisonneuve.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.L'adm inistrateur.René Perreault.55141-0 716309 PLACE NORBERT INC Avis est donné par les présentes que la compagnie «PLACE NORBERT INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 10 juilllet 1973 a établi son siège social au 3,100, boul.Cartier, Chome-dey_.Ville de Laval, dans le district de Montreal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Laval, ce 18 septembre 1973.Le président, 55142-0 Marcel Lalonde.MAISONNEUVE AUTOMOBILES INC Notice is hereby given that \"MAISONNEUVE AUTOMOBILES INC.\", incorporated in the Province of Québec, by letters patent granted pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act, dated November 19th 1971 and having its head office in the City of Québec district of Québec, Province of Québec, has established its office at 136 Maisonneuve.From and after the date of the present notice, the said office is considered by the company as being its head office.René Perreault, Administrator.55141-0 716309 PLACE NORBERT INC Notice is hereby given that \"PLACE NORBERT INC.\", incorporated by letters patent, de.ted July 10, 1973, has established its head office at 3.100 Cartier Boulevard, Chomedey, City of Laval, in the Distiict of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Laval, this eighteenth day of September, 1973.Marcel Lalonde, 55142 President.CANEXCO INC.La compagnie « CANEXCO INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 5, rue du Parloir, Québec, à Montminy (St-Paul), Montmagny.Le secrétaire.Raymond Blais.55190-o 885-64 CANEXCO INC.Notice is hereby given that \"CANEXCO INC.\" has transferred its head office from 5 Du Parloir Street, Quebec, to Montminy (St.Paul), Montmagny.Raymond Blais, Secretary.55190 885-64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7447 DUPUIS & GUERTIN INC.Avis est donné que la compagnie « DUPUIS & GUERTIN INC.».constituée en corporation en vertu de la première partie de la I.oi des compagnies par lettres patentes en date du 15e jour d'octobre 1973, et avant son siège social à Montréal a établi son bureau à 6931, rue St-Hubert.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 30e jour de novembre 1973.Le président.55156-0 Allan Glertin.DUPUIS & GUERTIN INC.Notice is hereby given that \"DUPUIS & GUERTIN INC.\", a company incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent on the 15th day of October.1973.and having its head office at Montreal, has established its office at 6931 St-Hubert Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 30th day of November, 1973.Allan Gubbttn, 55156-0 President.OXYGENE VAL-MAURICIE LTEE VAL-MAURICIE OXYGEN LTD.Avis est donné que la compagnie « OXYGENE VAL-MAURICIE LTEE \u2014 VAL-MAURICIE OXYGEN LTD.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 23e jour de juillet 1973, et ayant son siège social à Trois-Rivières a établi son bureau à 1125 Père Daniel.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Trois-Rivières, ce 26e jour de novembre 1973.Le président, 55157-0 François Roiillard.OXYGENE VAL-MAURICIE LTEE VAL-MAURICIE OXYGEN LTD.Notice is hereby given that \"OXYGENE VAL-MAURICIE LTEE \u2014 VAL-MAURICIE OXYGEN LTD.\", a company incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act by letters patent on the 23rd day of July.1973, and having its head office at Three Rivers, has established its office at 1125 Père Daniel.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Three Rivers, this 26th day of November, 1973.François Rouiillard, 55157-0 President.LA CORPORATION HOCKAIR IIOCKAIR CORPORATION Avis est par les présentes donné que « LA CORPORATION HOCKAIR \u2014 HOCKAIR CORPORATION », constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies en date du 27 mars 1973.et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au numéro 4109 est, rue Jarry.Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 31 octobre 1973.(Sceau) Le secrétaire, 55161-0 Jerry I.efson.LA CORPORATION HOCKAIR HOCKAIR CORPORATION Notice is hereby given that \"LA CORPORATION HOCKAIR \u2014HOCKAIR CORPORATION\", incorporated by letters patent issued under Part I of the Companies Act dated March 27, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 4109 Jarry Street East, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Dated at Montreal, this 31st day of October 1973.(Seal) Jerry Lefson, 55161-0 Secretary.CORPORATION BRISK BRISK CORPORATION La compagnie' CORPORATION BRISK \u2014BRISK CORPORATION » donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro S760.8e avenue, Saint-Michel, à Saint-Laurent.La secrétaire, Diane Granofsky.55201 5429-64 CORPORATION BRISK BRISK CORPORATION Notice is given that \"CORPORATION BRISK \u2014 BRISK CORPORATION\" has transferred its head office from 8760- 8th Avenue, Saint-Michel, to Saint-l.aurent.Diane Granofsky.Secretary.5520 l-o 5429-64 7448 QUEBEC OFFICI.il.GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.Xo.50 TRANSPORT R.ROCHON INC.Avis est donné que la compagnie « TRANSPORT R.ROCHON INC.» constituée en corporation par lettres patentes en date du vingt-quatre (24) novembre mil neuf cent soixante-douze (1972) et ayant son siège social à Saint-Canut, comté de Deux-Montagnes, a établi son bureau au numéro 101.boulevard St-Canut.à St-Canut, comté de Deux-Montagnes, district de Terrebonne.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme, étant son siège social.Donné à Saint-Jérôme, ce 31 mai, 1973.Le président.55200-o Roger Rochon.TRANSPORT R.ROCHON INC.Notice is given that \"TRANSPORT R.ROCHON INC.\".incorporated by letters patent dated the twenty-fourth (24th) of November one thousand nine hundred seventy-two (1972) and having its head office in St.Canut.County of Two Mountains, has established its office at 101 St.Canut Boulevard, in St.Canut, County of Two Mountains.District of Terrebonne.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the company as its head office.Given in St.Jérôme, this 31st of May one thousand nine hundred seventy-three (1973).Roger Rochon, 55200 President.LES ENTREPRISES CUBIC l.TEE Avis est donné que la compagnie « LES ENTREPRISES CUBIC LTEE n, constituée en corporation par lettres patentes en date du 11 avril 1973, et ayant son siège social dans le district de Terrebonne, a établi son bureau au 24, rue Aubry, à St-Sauveur-des-Monts, district de Terrebonne.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Signé ;i St-Sauveur-iles-Monts, ce .\"> -cptemblt 1973.(Sceau) Le président.Gilles Hroi.55202-o 731552 MEDYREL INC.Avis est donné que la compagnie « MEDYREL INC.\".constituée en corporation par lettres patentes accordées le deux (2) août mil neuf cent soixante-treize (1973) et enregistrées le quinze (15) août mil neuf cent soixante-treize (1973) Libre C.292.folio 16.et ayant son siège social en la ville de Saint-Jérôme, a établi son bureau au numéro « 265.rue Montignv.à Saint-Jérôme.p 9 k À compter de la date «lu present avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Le président.55205-o Bernard Bhiailt.LES ENTREPRISES CUBIC LTEE Notice is hereby given that \"LES ENTREPRISES CUBIC LTEE\".company incorporated by letters patent on the 11 tit day of April 1973, and having its head office in St-Sauveur-des-Monts, district of Terrebonne, lias established its office at 24 Aubry Street, St-Sauvcur-dos-Monts, district of Terrebonne.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Signed at St-Sauveur-des-MonLs.this September 5, 197.X.(Seal) Gilles Huot, President.55202-o 731552 .MEDYREL INC.Notice is given that \"MEDYREL INC.\".incorporated by letters patent granted on August two (2) one thousand nine hundred seventy-three (1973) and registered on August fifteen (15) one thousand nine hurdled seventy-three (1973) I.ibro C.292.folio 16, and having its head office in the City of St.Jérôme, has established its office at 265.Montigny Street, in St.Jérôme.P.Q.From the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as its head office.Bernard Briault, 55205 President.SNAP INDUSTRIAL CONSTRUCTION INC.La compagnie « SNAP INDUSTRIAL CONSTRUCTION INC\".».constituée em corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes émises le 21e jour de mai 1965, donne avis qu'elle h déménagé son siège social du 0540 rue Magloi-re.dans la cité de St-Léonard, au 9105, boulevard Pascal-Gagnon dans la cité de St-Léonard.Le 25 avril 1973.(Sceau) La secrétaire.55206-o Clara Halasz.SNAP INDUSTRIAL CONSTRUCTION INC.Notice is hereby given that \"SNAP INDUSTRIAL CONSTRUCTION INC.\".incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated May 21.1965.has moved its head office from 6540 Magloire Street in the City of St.Leonard to 9405 Pascal Gagnon Boulevard in the City of St.Léonard.April 25.1973.(Seal) Clara Halasz, 55206-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105- année, n\" 50 7449 CINEMA SHAWINIGAN INC.La compagnie « CINEMA SHAWINIGAN INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 632, 5e Rue.Shawinigan, au numéro 210, rue Crémazie ouest, Montréal.Le secrétaire, Pierre K.Garceau.55203-o 13550-55 CINEMA SHAWINIGAN INC.Notice is given that \"CINEMA SHAWINIGAN INC.\" has transferred its head office from 632 - 5th Street, Shawinigan, to 210 Crémazie Street West, Montreal.Pierre K.Garceau, Secretary.55203 13550-55 G.JOBIDON INC.La compagnie « G.JOBIDON INC.0 donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 48.rue Ramsay.Baie Comeau, au numéro 29.boulevard Ste-Adèle.Sainte-Adèle.La secrétaire, Claire Guichard.55204-q 15429-61 G.JOBIDON INC.Notice is given that \"G.JOBIDON INC.\" lias transferred its head office from 48 Ramsay Street, Baie-Comeau, to 29 Ste.Adèle Boulevard, Ste.Adèle.55204 Claire Guichard, Secretary.15429-61 Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act L'ASSOCIATION COOPERATIVE DES EDITIONS SOCIALISTES (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « L'ASSOCIATION COOPERATIVE DES EDITIONS SOCIALISTES », tenue à Montréal, le 26 octobre 1973, il a été résolu que les affaires de ladite association coopérative soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, ce en vertu des dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que MM.Gilles Bourquc.Jacques Dofny et Michel Van Schendel soient nommés liquidateurs.Le sous-ministre (par intérim) des institutions finaitcières, compagnies et coopératives.55160-o Albert Jessop.L'ASSOCIATION COOPERATIVE DES EDITIONS SOCIALISTES (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"L'ASSOCIATION COOPERATIVE DES EDITIONS SOCIALISTES\", held in Montreal on October 26, 1973, it was resolved that the affairs of said coopéralive association be wound up and that the latter be dissolved, the foregoing in conformity with the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-Up Act.and that Messrs Gilles Dourque, Jacques Dofny and Michel Van Schendel be appointed liquidators.55160 Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial I nstitutions.Companies and Cooperatives.ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE FABRE (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE FABRE ».tenue à Fa-bre, dans le district électoral de Pontiac-Témiscamin-gue.le 2 octobre 1973.il a été résolu que les affaires de ladite coopérative soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, ce en vertu des dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Florian Lafond soit nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).55192-0 Albert Jessop.ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE FABRE (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"ASSOCIATION COOPERATIVE FORESTIERE DE FABRE\" held in Fabre.in the Electoral District of Pontiac-Temiseamingue.on October 2.1973.it was resolved that the affairs of said cooperative be wound up and that the latter be dissolved, the foregoing pursuant to the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-Up Act.and that Mr.Florian Lafond be appointed as liquidator.55192 Albeht Jessop, Acting Deputy of Financial Institutions.Companies and Cooperatives. 7450 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, So.50 LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES (Loi des Caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de « LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES », tenue à Chute-des-Passes, le 22 octobre 1973.il a été résolu à l'unanimité que les affaires de ladite caisse soient liquidées et que celle-ci soit dissoute, en vertu île la Loi des Caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation îles compagnies, et que M.Eugène Roy soit nommé liquidateur.Québec, le 30 novembre 1973.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives {par intérim), 55184-0 Albert Jessop.PLACEMENT « BARON ¦ LIMITEE Avis est donne que, lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie « PLACEMENT « BARON » LIMITEE ».tenue à Montréal, le 1er novembre 1973, il a été résolu que les affaires de ladite compagnie soient liquidées, et que celle-ci soit dissoute, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Jean-Pierre Lefebvre.a été nommé liquidateur.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55135-0 11228-62 (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES\", held in Chute-des-Passes, on October 22, 1973, it was unanimously resolved that the affairs of the said Union be would up and that the latter be dissolved, in conformity with the Savings and Credit Unions Act and with the Winding-Up Act, and thai Mr.Eugène Roy be appointed liquidator.Québec, November 30, 1973.Albert Jessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions, 55184 Companies and Cooperatives.PLACEMENT \"BARON\" LIMITEE Notice is given that at a special general-meeting of the shareholders of \"PLACEMENT \"BARON\" LIMITEE\", held in Montreal on November 1.1973, it was resolved that the affairs of said Company he wound up and that the latter be dissolved, in conformity with the Winding-Up Act.and that Mr.Jean-Pierre Lefebvre be appointed liquidator.55135 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.11228-62 Demandes à la Législature Applications to Legislature Cité de Sherbrooke Avis est donné que la Cité de Sherbrooke déposera au Secrétariat des commissions de l'Assemblée nationale un projet de loi refondant sa charte et plus particulièrement: 1° Changeant son nom en celui de « Ville de Sherbrooke »; 2° L'autorisant à acquérir, construire des immeubles devant servir en totalité ou en partie à des fins municipales, vendre ou louer ces immeubles avec l'approbation de la Commission municipale du Québec, et à ces fins, contracter des emprunts et conclure des ententes avec des tiers sujet à des réserves quant à la participation de la ville dans les déficits; 3° L'autorisant à pourvoir elle-même ou par l'intermédiaire d'une corporation sans but lucratif à l'exploitation de centres de loisirs et de plein air dans un rayon de vingt milles en dehors de ses limites et à cette fin exercer tous les pouvoirs conférés par la Loi des cités et villes; 4° L'autorisant à détenir des permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout lieu public municipal: 5° Décrivant ses limites territoriales et divisant la ville en quatre quartiers connus sons les noms de quartiers nord, est.ouest et centre: City of Sherbrooke Notice is given that the City of Sherbrooke (Cité de Sherbrooke) will file with the Secretariat of Committees of the National Assembly a bill revising its charter, and, more specifically: 1.Changing its French name to that of Ville de Sherbrooke; 2.Authorizing it to acquire, and construct buildings to be used wholly or in part for municipal purposes, to sell or to lease said buildings with the approval of the Québec Municipal Commission, and, for such purposes, to contract loans and conclude agreements with third parties, subject to reservations as to the City's participation in the deficits; 3.Authorizing it to provide, on its own or through a non-profit corporation, for the operation of recreational and outdoor centres within a radius of twenty miles outside its limits and for this purpose to exercise all the powers conferred by the Cities and Towns Act; 4.Authorizing it to hold licences for the sale of alcoholic beverages in any public municipal establishment; 5.Describing its territorial limits and dividing the City into four wards known under the names of North, East, West and Centre Wards; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année.n° 60 7451 6° Décrétant que le conseil est composé du maire, de trois conseillers pour chacun îles quartiers nord, ouest et est et d'un conseiller pour le quartier centre; 7° Autorisant le conseil à nommer des comités d'études; 8° Décrétant le mode de publication d'un avis public donné par insertion dans les journaux sans formalité d'affichage; 9° L'autorisant à établir un tarif d'honoraires exigibles pour l'émission des certificats d'approbation des permis de construction; 10\" L'autorisant à réglementer les panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou à être érigés et prévoir l'enlèvement des enseignes non conformes aux règlements; 11° Décrétant que le coût des travaux encouru par la Cité pour faire respecter ses règlements de construction et de zonage constitue une créance privilégiée assimilahle>aux taxes foncières; 12° L'autorisant à réglementer l'installation de clôtures à neige; 13° L'autorisant à réglementer et prohiber la garde de certains animaux; 14° L'autorisant à établir les endroits où peuvent être situés des chantiers de matériaux de construction, en réglementer la hauteur et procéder à leur enlèvement lorsqu'ils constituent un danger; 15° L'autorisant à réglementer ou prohiber la vente, l'entreposage et l'usage des pièces pyrotechniques: 16° L'autorisant à réglementer la vitesse et l'usage d'embarcations à moteur sur les eaux situées à l'intérieur de ses limites et à prescrire toute autre mesure jugée utile pour la sécurité publique; 17° L'autorisant à décréter des travaux de construction, d'amélioration sur le domaine public et plus spécifiquement, la construction de mails, à sa charge ou à la charge des contribuables de partie ou de toute la ville; 18° L'autorisant, dans le cas île mails couverts, à obliger les propriétaires y attenants à se munir d'un système de protection contre les incendies; 19° L'autorisant à réglementer pour obliger les propriétaires de terrains situés en bordure d'une rue à construire et à entretenir des murs de soutènement, les construire et les entretenir elle-même, moitié à sa charge et moitié à la charge des propriétaires de la rue concernée; L'autorisant à répartir le coût de construction et d'entretien soit en raison de l'étendue en front ou de leur évaluation; 20° L'autorisant à approprier les revenus des terrains de stationnement au remboursement des emprunts contractés pour l'établissement de ces terrains; 21° L'autorisant à confier à toute personne, société ou corporation sans but lucratif, l'administration et la gestion de ses terrains de stationnement; 22° L'autorisant à décréter que dans le cas de contravention aux règlements de stationnement, toute personne dont les services sont retenus à cette fin peut remplir un billet d'assignation avec les mêmes pouvoirs conférés aux agents de police aux termes «le l'article 6.Enacting that the Council be composed of the Mayor, of three councillors for each of North, West and East Wards and of one councillor for Centre Ward ; 7.Authorizing the Council to appoint study committees; 8.Ordering the form of publication of a public notice given by insertion in newspapers without any posting formalities; 9.Authorizing it to establish a schedule of fees exigible for the issuing of certificates of approval of building permits; 10.Authorizing it to regulate respecting billboards and signs already erected or to be erected and make provision for the removal of signs that do not conform with regulations; 11.Enacting that the cost incurred by the City for works resulting from the enforcement of its building and zoning regulations constitutes a preferential debt classed as property taxes; 12.Authorizing it to regulate respecting the installation of snow-fences; 13.Authorizing it to regulate or prohibit the keeping of certain animals; 14.Authorizing it to determine those places where yards for building material may be located, regulate respecting their height and proceed to their removal when they constitute a hazard; 15.Authorizing it to regulate or prohibit the sale, storage and use of fireworks; 16.Authorizing it to regulate respecting the speed anil use of motor boats on waters located within its limits and to prescribe any other measure deemed advisable for public safety; 17.Authorizing it to enact that construction and improvement works be undertaken on the public property and, more specifically, the construction of malls, the costs thereof to be borne by the City or by taxpayers from part or from the whole City; 18.Authorizing it in the case of covered malls, to oblige proprietors whose property adjoins thereto to provide themselves with a fire protection system; 19.Authorizing it to provide regulations obliging proprietors of lots bordering on a street to construct and maintain retaining walls, to construct and maintain them itself, one half of such costs to be borne by the City, the other half by owners of properties on the street concerned; Authorizing it to apportion construction and maintenance costs either on the basis of street frontage or of their evaluation; 20.Authorizing it to appropriate the income from parking lots for the reimbursement of loans contracted for the construction of such lots; 21.Authorizing it to entrust the administration and management of its parking lots to any non-profit company, corporation or person: 22.Authorizing it to enact that, in the case of a violation of parking regulations, any person employed for the purpose be authorized to issue a notice of summons with the same powers as those conferred upon police officers under the terms of section 426 (17) of the 7452 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 426 (17) de la Ix>i des cités et villes et encourant les mêmes effets juridiques y mentionnés: 23° L'autorisant à expédier un avis d'infraction ou de rappel, selon le cas, à tout contrevenant aux règlements de circulation et de stationnement et à exiger, en sus de l'amende, une somme n'excédant pas $5.00 pour les frais de cet avis; 24° L'autorisant à réglementer la vitesse des véhicules automobiles dans son territoire sujet à affichage lorsque la vitesse excède celle permise par le Code de la route; 25° Lui donnant le privilège exclusif de vendre de l'électricité dans son territoire et l'autorisant à accorder ce privilège à toute personne: 26° L'autorisant à acquérir et à construire des usines pour la production de l'électricité, à en acheter, en louer ou en vendre dans son territoire ou dans un rayon de trente milles; 27° L'autorisant à affecter en premier lieu les revenus provenant de la vente de l'électricité au reml>oursenient des emprunts faits par le service de l'électricité; 28° L'autorisant à vendre ou à louer les réseaux et lignes de distribution d'énergie électrique sis hors de son territoire à la Commission hydro-électrique de Québec; 29° L'autorisant à conclure tout contrat pour la construction, la propriété et l'usage en commun de poteaux avec les compagnies de télécommunications; 30° L'autorisant à construire, acquérir, posséder et exploiter un service de transport en commun dans la ville et dans un rayon de dix milles; 31° L'autorisant à accorder une franchise exclusive pour une période n'excédant pas dix ans pour les services d'un transport en commun dans ses limites et de celles-ci à Lennoxville et retour.Cette franchise n'affecte aucun service de transport par autobus n'ayant que son terminus dans la ville et qui transportent des voyageurs du terminus à l'extérieur de la ville et vice-versa; 32° L'autorisant à fixer le nombre de membres composant la Commission du fonds de pension; 33° Décrétant l'obligation |x>ur le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sis flans une municipalité voisine et longeant une rue de la ville à acquitter le coilt du déneigement de la même manière qui sont tenues les personnes dont les terrains sont situés dans la ville, cette créance étant privilégiée au même rang que les taxes municipales: décrétant que si le coût de ce service est réparti sur la base de l'évaluation municipale «le ces immeubles, leur valeur réelle sert de base pour la répartition; 34° Autorisant à imposer une taxe annuelle sur tout habitant âgé de vingt et un ans et plus résidant dans lu ville depuis six mois et ne payant aucune autre taxe municipale; 35° L'autorisant à décréter par avis de motion et résolution l'exécution de travaux permanents de réfection et de construction de rues, trottoirs, chaînes de rues, d'amélioration et réparation du réseau électrique, de signalisation routière, d'égont et d'aqueduc, l'achat du materiel requis et des emprunts temporaires (x>ur dé- Cities and Towns Act and said notice to have the legal effects mentioned in said Act; 23.Authorizing it to send a notice of violation or of reminder, as the case may be, to any party contravening traffic and parking regulations and to demand, in addition to the fine, an amount not exceeding $5 to cover the cost of such notice; 24.Authorizing it to regulate respecting the speed of motor vehicles within its territory, subject to the posting of signs when the speed exceeds the speed permitted by the Highway Code; 25.Granting it the exclusive privilege of selling electricity within its territory and authorizing it to grant this privilege to any person; 26.Authorizing it to acquire and construct plants for the production of electricity, and to purchase, lease or sell same within its territory or within a radius of thirty miles; « ¦ \u2022 27.Authorizing it to appropriate the income deriving from the sale of electricity first of all for the reimbursement of loans contracted by the electricity department; 28.Authorizing it to sell or to lease to the Québec Hydro-Electric Commission the electric power supply networks and lines located outside its territory; 29.Authorizing it to enter into any agreement for construction purposes, for the ownership and the common use of posts with the telecommunication companies; 30.Authorizing it to build, acquire, own and operate a public transportation service in the City and within a ten-mile radius; 31.Authorizing it to grant an exclusive franchise for a period not exceeding ten years for public transportation services within its limits and thence to Lennoxville and return.This franchise does not affect any transportation service by bus having only its terminal in the City and carrying passengers outside the City from the terminal and vice-versa; 32.Authorizing it to fix the number of members for the Pension Fund Commission; 33.Enacting the obligation for the owner or the occupant of a property lying and situate in a neigh-liouring municipality and bordering on a street of the City to bear the cost of snow removal in the same manner as the persons whose property arc located in the City are obligated it; this debt being preferential on the same basis as municipal taxes; enacting that if the cost of this service is distributed on the basis of the municipal evaluation of those immoveables, their real value is used as the basis for the distribution: 34.Authorizing it to impose a yearly tax on any inhabitant aged twenty-one years or over who has been residing In the City for six months and who does not pay for any other municipal tax; 35.Authorizing it to order by notice of motion and resolution the performance of permanent works for repairing and building streets, sidewalks, and curbs, for improving and repairing the electric network, the system of road signs, sewers and waterworks, the purchase of the required equipment and temporary GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7453 frayer le coût de ces travaux pourvu que la somme n'excède pas $10,000,000 et ce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'approbation des propriétaires obligés mais avec les seules approbations du ministre des affaires municipales et de la Commission municipale de Québec et pour décréter par règlement un emprunt à long ternie au moyen d'émission d'obligations pour rembourser en tout ou en partie les emprunts temporaires; avant qu'ils n'atteignent la somme de $10,000,000 ce règlement ne requérant que les seules approbations du ministre des affaires municipales de la Commission municipale du Québec; 36° Décrétant que, sauf dans les cas où la loi permet des emprunts sur billets, tout emprunt doit se faire par voie d'émission d'obligations et pour régir les modalités des signatures qui doivent y être apposées; 37° Décrétant que, dans le cas d'expropriation partielle d'un immeuble par la Cité, celle-ci |ieut en exproprier ou en acheter de gré la totalité lorsqu'elle estime avantageux de ce faire, en raison des dommages causés; 38° Décrétant comme suffisant la simple énonciation de la loi ou du règlement concernés dans toute action ou plainte portée devant la Cour municipale; 39° Décrétant que tout mandat (l'emprisonnement émis par la Cour municipale peut être exécuté dans tout district judiciaire par un constable ou agent de la paix; 40° Décrétant que tout emprisonnement imposé par un juge de la Cour municipale puisse être purgé dans la prison commune du district où le mandat d'emprisonnement est exécuté; 41° Autorisant sa commission athlétique à faire des règlements pour sa régie interne, les conditions d'obtention et usages des permis, la préparation, l'organisation et la tenue i, le ministre des terres et forêts a fait déposer: 1.le 5 octobre 1973, aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, ces plan et livre de renvoi; 2.le 15 octobre 1973.au bureau de la division d'enregistrement de Bonaventure No 1.à New-Carlisle, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.le 9 octobre 1973, au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de Paspébiac, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4063-73, du 8 novembre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la \\jO\\ des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), qu'il y a lieu : a) de fixer à la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Bonaventure, pour le cadastre d'une partie du canton de Cox, c'est-à-dire la partie comprenant les lots 190 à 232 et 235 à 299.premier rang de Paspébiac, 338 à 401 et 403 à 424 de la Commune de Paspébiac et 425 à 440 et 442 à 452, deuxième rang île Paspébiac et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Bonaventure No 1 ; b) d'indiquer que ces plan et livre de renvoi révisés sont déposés aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, et.qu'en outre, le ministre des terres et forêts a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi revisés au bureau de la division d'enregistrement de Bonaventure No 1, à New-Carlisle, ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de Pasbébiac; c) d'informer le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de Proclamation Whereas, under the provisions of section 2 of the Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 321), the Minister of Lands and Forests has caused to be drawn up a revised plan and book of reference in the Electoral District of Honaventure.for the cadastre of a part of the Township of Cox, namely the part comprising lots 190 to 232 and 235 to 299, in the First Range of Paspébiac, 338 to 401 anil 403 to 424 in the Municipality of Paspébiac and 425 to 440 and 442 to 452 in the Second Range of Paspébiac.and their respective subdivisions, the whole located in Bonaventure Registration Division No.1 ; Whereas, in conformity with sections 2 and 3 of said Act, the Minister of Lands and Forests caused to be deposited: 1.on October 5, 1973, in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, this plan and book of reference; 2.on October 15, 1973, in the Bonaventure Registration Division No.1 Office, in New-Carlisle, a certified copy of said plan and book of reference: 3.on October 9, 1973, in the office designated by him.namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of Pasbépiac.a certified copy of said plan and l>ook of reference: Whereas it is now expedient to issue the proclamation provided for in section 4 of said Act.Therefore, with the consent and advice of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 4063-73.dated November 8.1973.We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and in conformity with sections 2.3 4 and 5 of the Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 321).that it is expedient: (a) To fix the date of the second and final consecutive publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle as the date of the coming into force of the revised plan and book of reference, in the Electoral District of Bonaventure, for the cadastre of a part of the Tonwship of Cox, namely that part comprising lots 190 to 232 and 235 to 299 in the First Range of Paspébiac.338 to 401 and 403 to 424 in the Municipality of Paspébiac and 425 to 440 and 442 to 452, in the Second Range of Paspébiac and their respective subdivisions, the whole located in Bonaventure Registration Division No.1 : (6) To state that the said revised plan and l>ook of reference have been deposited in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, and that, moreover, the Minister of Lands and Forests has caused a certified copy of said revised plan and book of reference to be deposited in the Bonaventure Registration Division No.1 Office, in New-Carlisle, as well as in an office designated by him, namely that of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of Paspébiac; (c) To inform the public that during the eight months following upon the second and final publication of this GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7463 cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi revisés; d) de porter notification qu'à l'expiration de ce délai le ministre des terres et forêts délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) d'ordonner que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan et un livre de renvoi revisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; /) d'informer aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'iionorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce huitième jour de novembre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Le .sous-procureur général adjoint.Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 175 54960-49-2-o proclamation in the Québec Officiai Gazelle, any interested party may examine, free of charge, the said revised plan and book of reference: (d) To give notice that when such time-limit expires, the Minister of Lands and Forests will issue a certificate of ownership to any occupant of the immoveable, with or without title, even though he be only an administrator or an operator of such immoveable, unless an interested party objects in writing; («) To order that any real right affecting a lot comprised in the aforesaid territory for which a revised plan and book of reference have been deposited be renewed, within the same period, in the manner prescribed by articles 2172 and 2172a of the Civil Code; (/) To inform the public also that, failing such renewal, the real rights preserved by the first registration shall have no effect as regards other creditors or subsequent purchasers whose rights are duly registered.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Huguf:.s Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this eighth day of November in the year of Our Lord, one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 175 54960-49-2 Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth.Défenseur de la foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi des titres de propriétés dans certains districts électoraux (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 321), le ministre des terres et forêts a fait dresser des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Gas-pé (antérieurement Gaspé-Sud), pour le cadastre d'une partie du canton de Percé à l'endroit des lots 120 à 170 Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, under the provisions of section 2 of the Certain Electoral Districts Land Titles Act (Revised Statutes of Québec, 1964.Chapter 321), the Minister of Lands and Forests has caused to be drawn up a revised plan and book of reference in the Electoral District of Gaspé (formerly Gaspé-South), for the cadastre of a part of the Township of Percé, with 7464 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15.1973.Vol.105, No.50 inclusivement, 1251 et 1252 rang 1 Est du Cap-d'Es-poir à Anse-à-Beaufils et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Gaspé; Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite loi, le ministre des terres et forets a fait déposer: 1.le 24 octobre 1973, aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, ces plan et livre de renvoi: 2.le 29 octobre 1973, au bureau de la division d'enregistrement de Gaspé, à Percé, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi; 3.le 24 octobre 1973, au bureau désigné par lui, à savoir celui du secrétaire-trésorier de la corporation municipale de la ville de Percé, une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi: Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4238-73, du 21 novembre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi des titres de propriété dans certains districts électoraux (Statuts refondus (lu Québec, 1964, chapitre 321), qu'il y a lieu: a) de fixer à la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, l'entrée en vigueur des plan et livre de renvoi revisés, dans le district électoral de Gaspé (antérieurement Gaspé-Sud), pour le cadastre d'une partie du canton de Percé à l'endroit des lots 120 à 170 inclusivement, 1251 et 1252 rang 1 Est du Cap-d'Es-poir à Bcaufils et de leurs subdivisions respectives, le tout situé dans la division d'enregistrement de Gaspé; b) d'indiquer que ces plan et livre de renvoi revisés sont déposés aux archives du ministère des terres et forêts, à Québec, et, qu'en outre, le ministre des terres et forêts a fait déposer une copie certifiée de ces plan et livre de renvoi revisés au bureavi de la division d'enregistrement de Gaspé, à Percé: c) d'informer le public que, pendant les huit (8) mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazelle officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement lesdits plan et livre de renvoi révisés; d) de porter notification qu'à l'expiration de ce délai le ministre des terres et forêts délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) d'ordonner que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan et un livre de renvoi revisés ont été déposés soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du code civil; regard to lots 120 to 170 inclusive, 1251 and 1252 in Range 1 East of Cap-d'Espoir in Anse-à-Beaufils.and their respective subdivisions, the whole located in the Gaspé Registration Division; Whereas, in conformity with sections 2 and 3 of said Act, the Minister of Land-and Forests caused to be deposited: 1.on October 24, 1973, in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, this plan and book of reference; 2.on October 29, 1973, in the Gaspé Registration Division Office, in Percé, a certified copy of said plan and book of reference; 3.on October 24, 1973, in the office designated by him, namely the office of the Secretary-Treasurer of the Municipal Corporation of the City of Percé, a certified copy of said plan and book of reference; Whereas it is now expedient to issue the proclamation pro vised for in section 4 of said Act.Thfrefore, with the consent and advice of Oui Executive Council, expressed in a decree numbered 4238-73, dated November 21, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upor, the recommendation of the Minister of Lands and Forests and in conformity with sections 2.3, 4 and 5 of the Certain Electoral' Districts Land Titles Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 321), that it is expedient: (a) To fix the date of the second and final consecutive publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle as the date of the coming into force of the revised plan and book of reference, in the Electoral District of Gaspé (formerly Gaspé-South).for the cadastre of a part of the Township of Percé with regard to lots 120 to 170 inclusive, 1251 an 1252 in Range 1 East of Cap-d'Espoir in Anse-à-Beaufils, and their respective subdivisions, the whole located in the Gaspé Registration Division; (6) To state that the said revised plan and bock of reference have been deposited in the Archives of the Department of Lands and Forests, in Québec, and that, moreover, the Minister of Lands and Forests has caused a certified copy of said revised plan and book of reference to be deposited in the (Jaspé Registration Division Office, in Percé; (c) To inform the public that during the eight (8) months following u]>on the second and final publication of this proclamation in the Québec Official Gazelle, any interested party may consult, free of charge, the said revised plan and book of reference; (d) To give notice that when such time limit, expires, the Ministci of Lands and Forests will issue a certificate of ownership to any occupant of the immoveable, with or withouttitlc, even though he be only an administrator or an operator of such immoveable, unless an interested party objects in writing: (e) To order that any real right affecting a lot comprised in the aforesaid territory for which a révisée! plan and book of reference have been deposited be renewed, within the same period, in the manner prescribed by articles 2172 and 2172a of the Civil Code; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' aimée, n° 50 7465 /) (l'informer aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De toit ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Ex foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., cit., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-et-unième jour de novembre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 Jean Alarie.Folio: 180 55176-50-2-o (/) To inform also the public that, failing such renewal, the real rights preserved by the first registration shall have no effect as regards other creditors or subsequent purchasers whose rights are duly registered.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly.In testimony whereof.We have caused these Oui present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lai'ointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City cf Québec, in Our Province of Québec, this twenty-first day of November in the year of Our I.ord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.Bj command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 180 55176-50-2 Canada, Province de HUGUES I.APOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la F'oi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Grenier, comprenant les lots 93 et 94, rang A, située dans la division d'enregistrement de Saguenay, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre îles terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagné d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay, à Baic-Coineau; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, scion les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Saguenay, et, en même Canada, Province of HUGUES LA POINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories.Queen.Head of the Commonwealth.Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Gheeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec.1964.chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Grenier, comprising lots 93 and 94 in Range A, located in the Saguenay Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan ; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Saguenay Registration Division Office, in Baie-Comeau, by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Saguenay Registration Division, and.at the same QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 7466 temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Grenier; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4239-73, du 21 novembre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent », qu'il y a lieu; a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Saguenay.à Buie-Comcau, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton do Grenier, com prenant les lots 93 et 94 rang A, située dans la division «l'enregistrement de Saguenay; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement :i ladite partie du canton de Grenier; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, «l'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou «les acquéreurs subséquents dont les droits sent régidièrement enregistrés.De toit ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.E\\ foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Huches Lai-ointe, c.p.ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt et unième jour de novembre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 5111 Jean Ai.aiiie.Polio: 177 55121-0 time, the day on which the provisions of article 2168 will l»ecome effective, the whole in relation to the said part of the Township of Grenier; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 4239-73, dated November 21.1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec.1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say.those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Saguenay Registration Division Office, in Baie-Comeau, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Grenier, comprising lots 93 anrl 94 in Range A.located in the Saguenay Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (4) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Grenier; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of ai.i.of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.c.q.c.Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Quebec, in Our Province of Québec, this twenty-first day of November in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 177 55121 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n\" 50 7467 Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.IL.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu.Reine du Royaume-Uni.du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe o du paragraphe 24 de l'article 61 de la Loi de l'interprétation (Statuts refondus du Québec.1964.chapitre 1) et du paragraphe j de l'article 6 du Code de procédure civile, le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par proclamation tout jour de l'année comme jour de fête publique et jour non juridique; Attendu Qu'il est à propos de déclarer jours fériés, jours de fêtes publiques et jours non juridiques les 26 décembre 1973 et 2 janvier 1974; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 4190-73, du 21 novembre 1973, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la justice; Que, sous l'autorité de la Loi de l'interprétation et du Code de procédure civile, les 26 décembre 1973 et 2 janvier 1974 soient, pour la province de Québec, jours fériés, jours de fêtes publiques et jours non juridiques.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p.c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hotel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt et unième jour de novembre en l'année mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-deuxième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint.Libro: 501 Jean Alarie.Folio 179 55121-0 Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.IL.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas pursuant to paragraph o of subsection 24 of section 61 of the Interpretation Act (Revised Statutes of Quebec.1964.Chapter 1) and to paragraph j of article 6 of the Code of Civil Procedure, the Lieutenant-Governor in Council may fix by proclamation any day of the year as a public holiday and non legal day; Whereas it is expedient to proclaim December 26, 1973 and January 2, 1974 public holidays and non legal days; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 4190-73, dated November 21, 1973, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Justice; That, under the au tori ty of the Interpretation Act and of the Code of Civil Procedure, December 26, 1973 and January 2, 1974 be.for the Province cf Québec, public holidays and non legal days.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-first day of November in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-three and in the twenty-second year of Our Reign.By command, Jean Alarie, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 179 55121 7468 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105.No.50 Ventes par Shérifs Sheriff's Sales AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.BONAVENTURE Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Bonaventure J^A CAISSE POPULAIRE DE ST- { No 3804.\\ ^ OMER.demanderesse, » ANDRE ARSENAULT, défenderesse.R.R.No 1, St-Omer.comté de Bonaventure.Description « Un certain terrain situé à Mission St-Louis dans le comté de Bonaventure.dans le troisième rang du canton Nouvelle, étant le tiers est du lot numéro onze (1/3 E.de 11) desdits rang et canton, contenant trente-trois acres et un tier (33 1/3) en superficie, plus ou moins, et borné comme suit, savoir: au sud par le chemin entre le rang 2 et le rang 3, du canton Nouvelle, au nord par le quatrième rang, à l'est par le lot numéro 10 et à l'ouest par une partie du lot 11 actuellement en la possession de Joseph Thériault, avec une maison dessus construite, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement, deuxième division à Carleton.comté de Bonaventure, le DIX-HUITIÈME jour de JANVIER.1974 à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.New-Carlisle.P.Q.Le shérif.Camiuen Bisson.55163-o No.BONAVENTURE Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Bonaventure l J A CAISSE POPULAIRE DE ST-3804.-J *¦> OMER, plaintiff, es ANDRÉ ARSE-l NAULT.defendant.R.R.No 1, St-Omer, County of Bonavendure.Description \"A certain piece or portion of land situated at St-Louis Mission in the County of Bonaventure.in the Third Range of the Township of Nouvelle, known and described as being the Third East of lot number eleven, (1/3 E.of 11), of the said range and township, containing thirty-three acres and one third in superficies, (33 1/3), more or less, and bounded as follows: to the south by the road between the 2nd range and the 3rd range of the Township of Nouvelle, to the north by the Fourth Range, to the east by lot number 10 and to the west by a part of lot 11 at the present time in possession of Joseph Thériault, with house thereon erected, circumstances and dependencies.\" To be sold at the office of the registrar of the Second Registration Division for the District of Bonaventure.at Carleton.P.Q.on the EIGHTEENTH day of JANUARY 1974.at TEN o'clock in the forenoon.Camiliex Bisson, Sheriff's Office, Sheriff.New-Carlisle.Que.55163-o Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Bonaventure ( JOSEPH J.GRENIER, demanderesse, w No 3987.S J ALBERIC LAN G LOIS, défendeur.Un immeuble situé à Gascons (Bonaventure), comprenant: a) L'n morceau de terrain connu et désigné comme une partie du lot numéro trois cent quarante-trois (P.343) aux plan et livre de renvoi officiels du canton «le Port-Daniel, première division d'enregistrement de Bonaventure (New-Carlisle), sans bâtisse.Ce morceau de terrain mesure un quart d'arpent de large moins parlir du chemin public sur trois arpents de profondeur plus ou moins qui est de soixante-huit pieds de largeur, sur toute la profondeur du lot borné au sud par le chemin public, à l'est par la propriété de Philippe Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Bonaventure ( JOSEPH .1.GRENIER, plaintiff, to AL-No.3987.< j BERIC LANGLOIS, defendant.An immoveable property situated at Gascons (Bonaventure).and described as follows: (a) A certain piece or portion of land known and described as part of lot number three hundred and forty-three.(Pt.343), of the official plan and book of reference for the Township of Port-Daniel.First Registration Division of the County of Bonaventure, (New-Carlisle), without buildings.This piece of land measures one quarter of an arpent in width less from the public highway three arpents in depth, more or less, by sixty-eight feet in width, by the whole depth of the lot and bounded to the south by the Public Highway, to the east by the property of Phi- GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105- année, n° 50 7469 Huard ou représentants au nord par le trait carré et à l'ouest par le morceau de terrain ci-après décrit.ii) Un second morceau de terrain connu et désigné comme une partie du lot numéro trois cent quarante-B (P.340-B) rang 1 est, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Port-Daniel, première division d'enregistrement de Bonaventure (New-Carlisle), apparte ¦ nances et dépendances.Ce morceau de terrain mesure vingt-quatre pieds de largeur sur une profondeur d'environ dix-sept arpents et est borné en front par le terrain ci-dessus désigné, à l'est par le même morceau, à l'ouest par la propriété de Ludger Morin et en arrière par la propriété de Benjamin Anglehart ou représentants.Pour être vendu « en bloc » au bureau d'enregistrement de la division 1 au palais de Justice de New-Carlisle, comté et district de Bonaventure.le DIX-SEPTIÈME jour de JANVIER 1974.à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du shérif, Camilien Bisson.New-Carlisle, Que.55177-o HAUTERIVE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Hauterive (\"/Corporation municipale de No 14195.4 RAGUENEAU.demandeur es < LOUIS PHILIPPE DESROSIERS, défendeur.Une propriété immobilière étant partie du lot 45, Rang 2, ayant une superficie de 74' x 76' borné au nord par la route du Rang 2, au sud par le résidu du lot 45, à l'est par la propriété de Charles Edouard Gagnon, à l'ouest par le terrain appartenant à Jacques Emond, aux plan et livre de renvoi de Canton Rague-neau, municipalité de Ragueneau.Pour être vendu au bureau du registrateur de la première division d'enregistrement de Saguenay, au Palais de Justice de Baie Comeau.le VINGT-DEUXIÈME jour du mois de JANVIER 1974 à 2.30 heures de l'après-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif adjoint, Charlotte Bergeron.Baie Comeau.55164-o MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal t X/TOUNT ROYAL TILE AND No 05-005719-73.-» ivl TERRAZZO INC.compa-l gnie dûment constituée en corporation, ayant son principal bureau d'affaires dans le district de Montréal au numéro 11315, 7c avenue.Ri- lippe Huard or representatives, to the north by the base line and to the west by the piece of land hereinafter described.(6) A second piece of portion of land known and described as part of lot number three hundred and forty-B.(Pt.340-B).1st Range East, of the official plan and book of reference for the Township of Port Daniel.First Registration Division for the County of Bonaventure (New-Carlisle), circumstances and depencencies.This piece of land measures twenty-four feet in width by a depth of about seventeen arpents and is bounded in front by the land above described, to the east by the same piece of land, to the west by the property of Ludger Morin and to the north by the property of Benjamin Anglehart of representatives.To be sold \"in block\" at the Registry Office.First Division, at the New Carlisle Court House, County and District of Bonaventure, on the SEVENTEENTH day of JANUARY 1974.at TEN o'clock before noon.Camilien Bisson, Sheriff's Office, Sheriff.New Carlisle, Que.55177-0 HAUTERIVE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Hauterive (\\XUNICIPAL CORPORATION OF No.14195.{ LVi.RAGUENEAU, plaintiff, versus orné au nord-est par la partie ci-haut décrite du lot numéro 199-161, au sud-est par la rue Beaubien, au sud-ouest par le résidu dudit lot numéro 199-160 et au nord-ouest par une ruelle (199-163), mesurant vingt et un pieds et seize centièmes île pied (21.16') le long de la.rue Beaubien, dans sa ligne sud-est, cent six pieds et six dixièmes de pied (106.6') ilans sa ligne nord-est et cent trois pieds et cinquante-huit centièmes de pied (103.58') dans sa ligne sud-ouest, ayant une superficie île deux mille deux cent vingt-trois pieds et soixante et onze centièmes de pieds carrés (2.223.71 pi.car.), le tout mesure anglaise et plus ou moins.» Avec la bâtisse dessus construite et portant le numéro civique 3815, rue Beaubien.Est.à Montréal.Pour être vendu au bureau du Shérif, un Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le DIX-SEPTIEME jour de JANVIER 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Paix St-Mautix.Montréal, ce 5 décembre 1973.55165-n Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior ( ourt I >i-t rict of \\Ionl real ( O .VISSE POPULAIRE DE ST-No.05-002535-73.< MARC DE ROSEMONT, * a corporation legally incor|x>ratcd, having its principal place of business at 2597 Beaubien Street East, in the City and District of Montreal, plaintiff, vs DANIEL COULOMBE.residing and domiciled at 4595 Notre-Dame Street.Chcmedey.I,aval.District of Montreal, defendant, and THE REGISTRAR for the Montreal Registration Division, mil en cause.\"An emplacement fronting on Beaubien Street East, in the City of Montreal, known and described as comprising: (a) The southwesterly part of lot number one hundred sixty-one of the official subdivision of original lot number one hundred ninety-nine (199-161 S.W.Pt) on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte-de-la-Visitation, Montreal Registration Division, bounded on the northeast by the northeasterly part of lot number 199-161.on the southeast by Beaubien Street, on the southwest by the northeasterly part of lot number 199-160.and on the northwest by a lane (199-163), measuring four and forty-two hundredths feet (4.42') in width along Beaubien Street, by one hundred seven and twenty-two hundredths feet (107.22') in depth on its northeast line and one hundred six and six tenths feet (106.6') on its southwest line, covering a surface area of four hundred seventy-two and sixty-five hundredths square feet (472.65 sq.ft), the whole English measure and more or less.The northeasterly part of lot number one hundred sixty of the official subdivision of original lot number one hundred ninety-nine (199-160 N.E.Pt) on said official plan and in said l>ook of reference.Iiounded on the northeast by the above-described part of lot number 199-161.on the southeast by Beaubien Street, on the southwest by the remainder of said lot number 199-160 and on the northwest by a lane (199-163), measuring twenty-one and sixteen hundredths feet (21.16') along Beaubien Street, on its southeast line, one hundred six and six tenths feet (106.6') on its northeast Hue and one hundred three and fifty-eight hundredths feet (103.58') on its southwest line, covering a surface area of two thousand two hundred twenty-three and seventy-one hundredths square feet (2,223.71 sq.ft), the whole English measure anil more or less.\" With the building erected thereon and heeling civic number 3815 Beaubien Street East, in Montreal.To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in the Citv of Montreal, 10 Craig Street East.10th Floor.Room 56.on the SEVENTEENTH day of JANUARY.1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Pah.St-Mautin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal.Decembers.1973.55165 7472 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 15.1973.Vol.105.No.50 Fieri Farias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montreal No 02-027351-73, l T IONEI.GUAY, de la vil-Ex-parte: 18-001272-73.S |e ç\\e Kirkland.district ^ de Montréal, et y exerçant seul un commerce sous la raison sociale de I.G.Plumbing Reg'd, au 3050, route Saint-Charles, demandeur, m Dame DIANNE SMITH CUBELL, de la ville de Pointe-Claire, district de Montréal et y résidant et domiciliée au 72, King's Roail, défenderesse.« Ce certain emplacement ayant front sur King's Road, Valois en la ville de Pointe-Claire, comprenant les lots de subdivision numéros deux cent cinquante-cinq et deux cent cinquante-six de la subdivision du lot originaire numéro cinquante-huit (58-255.250) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Pointe-Claire, mesurant quarante pieds (40') de largeur sur cent vingt pieds (120') de profondeur, mesures anglaises et plus ou moins, avec une bâtisse y érigée portant le numéro civique 72.King's Road, Valois.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice en la ville île Montréah 10.rue Craig est, 10e étage, chambre 56, le SEIZIÈME jour du mois de JANVIER 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Mahtix.Ce 4 décembre 1973.55170 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province île Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"D ENÉ CARON, rentier, rési-No 05-010706-73.S *\\ dant et domicilié au No 246.* Chemin Ste-Catherine, Cité d'Ou-tremont, demandeur; iw GEORGES PELISSIER, gérant, résidant et domicilié au No 3445, rue Gascon, app.8, Montréal, défendeur.« Un emplacement ayant front sur la rue Casgrain, en la Cité de Montréal, mesurant trente pieds deux pouces et demi de largeur par soixante-dix-huit pieds de profondeur, et étant composé: n) d'un lot de terre connu et désigné auxdits plan et livre de renvoi officiels du Village Incoriioré de la Côte St-Louis.comme étant la subdivision numéro un de la subdivision numéro deux cent cinquante-quatre dudit lot originaire numéro dix (10-254-1).mesurant douze pieds cie largeui par la profondeur susmentionnée.6) d'un autre lot île terre cjniiu et désigné auxdits plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte St-Louis.comme étant la subdivision numéro un de la subdivision numéro deux cent cinquante-cinq dudit lot originaire numéro dix (10-255-1) contenant dix-huit pieds et deux pouces et demi de largeur par soixante-dix-h'.iit pieds de profondeur.Avec une maison en bois et brique à trois étages comprenant six logements portant les numéros 5442 à 5452 de ladite rue Casgrain.et autres bâtiments dessus érigés.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.02-027351-73, l T IONEI.GUAY.of the Ex-parle: 18-001272-73.< City of Kirkland.Dis-* trict of Montreal, and therein carrying on business alone under the firm name and Style of L.G.Plumbing Reg'd, at 3050 St.Charles Road, plaintiff, es Dame DIANNE SMITH CUBELL, of the City of Pointe Claire, District of Montreal and therein residing and domiciled at 72 King's Road, defendant.\"That certain emplacement fronting on King's Road.Valois in the City of Pointe Claire, composed of subdivision lot numbers two hundred and fifty-five and two hundred and fifty-six of the subdivision of original lot number fifty-eight (58-255, 256) on the official plan and book of reference of the parish of Pointe-Claire measuring forty feet (40') in width each by one hundred and twenty feet (120') in depth English measure and more or less with a building thereon erected bearing civic No.72 King's Road, Valois.\" To be sold at the Sheriff's Office.Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th floor, Room 56, on the SIXTEENTH day of JANUARY 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Maiitin, Superior Court.Assistant Sheriff.Montreal, December 4.1973.55170-o Fitri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal (T3ENÉ CARON, annuitant.No.05-010706-73.S residing and domiciled at 246 l Ste.Catherine Road, City of Outremont, plaintiff, versus GEORGES PELISSIER, manager, residing and dociled at 3445 Gascon Street, Apartment 8, Montreal, defendant.\"An emplacement fronting on Casgrain Street, in the City of Montreal, measuring thirty feet two inches and a half in width by seventy-eight feet indepth, and consisting of: (a) a piece of land known and described on said official plan and in said book of reference for the Incorporated Village of Côte St.Louis, as being subdivision number one of the subdivision number two hundred fifty-four of said original lot number ten (10-254-1), measuring twelve feet in width by the aforementioned depth.(6) another piece of land known and described on -aid official plan and in said book of reference for (he-Incorporated Village of Côte St.Louis, as being subdivision number one of the subdivision number two hundred fifty-five of said original lot number ten (10-225-1) measuring eighteen feet and two inches and a half in width by seventy-eight feet in depth.With a three-story wood and brick house comprising six apartments, bearing numbers 5442 to 5452 of said Casgrain Street, and other buildings erected thereon. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n' 50 7473 Avec droit de passage en commun avec d'autres dans la ruelle en arrière et dans les ruelles communiquant de cette ruelle à ladite rue Casgrain.* Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1974, à DIX heures et TRENTE de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Pali.St-Martin.Montréal, ce 30 novembre 1973.55167-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Quebec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal No 02-044268-72.t TA VILLE DE LAVAL, corpora-Ez-Parte: ) ™ lion légalement constituée et 18-001322-73.J ayant son siège social à Laval, dis-l trict judiciaire de Montréal, demanderesse, vs CHARLES E.LAROSE, domicilié à Dorval, district de Montréal, défendeur, et LE RE-(ïISTRATEUR de la division d'enregistrement de Laval, mis en cause.< Un emplacement situé à Laval, connu et désigné comme étant le lot numéro deux cent vingt-sept du lot originaire numéro trois cent quarante-neuf (349-227) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Martin.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval.155.boulevard Je-Mc-Souviens.à Laval.P.Q.le DIX-SEPTIÈME jour de JANVIER 1974.à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martin.Montréal, le 4 décembre 1973.55169 fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"D ENÉ CARON.rentier, rési-No 05-010707-73.S LV dant et domicilié au No 246.I Chemin Ste-Catherine.Cité d'Ou-tremont, demandeur, vs GEORGES PELISSIER, gérant, résidant et domicilié au No 3445, rue Gascon, app.No 8, Montréal, défendeur.« Un emplacement ayant front sur la rue Casgrain, en ladite cité de Montréal, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du village incorporé de la Côte St-lxiuis, comme étant la subdivision numéro deux de la subdivision numéro deux cent cinquante-sept du lot originaire numéro dix (10-257-2), mesurant trente pieds et quatre pouces de largeur par soixante-dix-huit pieds de profondeur, avec une maison en liois et brique ù trois étages comprenant six logements, portant les numéros 5466 à 5476 de ladite rue Casgrain, et autres bâtiments dessus érigés.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUINZIÈME jour de JANVIER 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Pail St-Martin.Montréal, ce 3 décembre 1973.55166-o With a right of way in common with others in the lane in the rear and in the lanes communicating from this lane to said Casgrain Street.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FIFTEENTH day of JANUARY, 1974, at TEN-THIRTY o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, November 30, 1973.55167-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.02-044268-72.1 HTHE CITY OF LAVAL, a cor-Ex-Parte: ) *\u2022 poration legallv incorporated 18-001322-73.j and having its head office in La-\\ val.Judicial District of Montreal, plaintiff, vs CHARLES E.LAROSE.domiciled at Dorval, district of Montreal, defendant and THE REGISTRAR for the Laval Registration Division, mis-en-cause.\"An emplacement in Laval known and designated as lot number two hundred and twenty-seven of original lot number three hundred and forty-nine (349-227) on the official Plan and Book of Reference of the Parish of St-Martin.\" To be sold at the Laval County Registry Office.155, Je-Me-Souviens Boulevard, in Laval, P.Q., on the SEVENTEENTH day of JANUARY 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant sheriff.Montreal.December 4.1973.55169-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( TJ ENÉ CARON.annuitant, re-No.05-010707-73.S -EN.siding and domiciled at 246 v Ste.Catherine Road.Citv of Outremont, plaintiff, vs GEORGES PELISSIER, manager, residing and domiciled at 3445 Gascon Street.Apt.8.Montreal, defendant.\"An emplacement fronting on Casgrain Street in said City of Montreal, known and described on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte St.Louis, as being subdivision number two of subdivision number two hundred fifty-seven of original lot number ten (10-257-2), measuring thirty feet and four inches in width by seventy-eight feet in depth, with a three-storied wood and brick house, comprising six apartments, bearing numbers 5466 to 5476 of said Casgrain Street, and other buildings erected thereon.\" To be sold at the Sheriff's Office in the Court House of the Citv of Montreal, 10 Craig Street East.10th Floor, Room 56, on the FIFTEENTH day of JANUARY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul SL-Mahtin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, December 3, 1973.55166 7474 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal I flANADA FLOORING LIMI-No 05,004,920/73.< v~/ TED, corporation légale-l' ment constituée ayant sor.siège social et sa principale place d'affaires dans les cité et district de Montréal, demanderesse, va MARCEL MASSE, résidant et domicilié à Pointe-aux-Tremblcs, district de Montréal, défendeur.L'immeuble ci-après désigné et en la possession du défendeur, savoir: « Un emplacement connu et désigné sous le numéro trois cent vingt-deux de la subdivision officielle du bloc C (Bloc C-322) du canton d'Howard, division d'enregistrement d'Argenteuil.Avec bâtisses dessus érigées.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil, situé à 430 rue Grâce.Lachute.P.Q.MARDI, le QUINZIEME jour de JANVIER 1974, à QUATORZE heures, p.m.de l'après-midi.Le ahêrif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Muih.Saint-Jérôme, le 3 décembre 1973.55143-0 Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Terrebonne C O ENTRE D'ALUMINIUM DE No 16,514.< v> MONTREAL LTEE, corporation » dûment constituée en corporation, ayant son principal établissement en les ville et district de Montréal, demanderesse, va Dame HERVÉ BÉLANGER, résidant et domiciliée au Lac-Carré, district de Terrebonne, défenderesse.L'immeuble ci-après décrit: « Un lopin de terre faisant partie du lot numéro un de la subdivision officielle du lot originaire numéro vingt-huit «A» (28A-P.1) du rang sept (VII), du canton Wolfe, au cadastre dudit canton; Mesurant cedit lopin de terre, cinquante pieds (50') de largeur du non! au sud sur soixante-quinze pieds (75') de profondeur de l'est à l'ouest; Borné, cedit lopin de terre, en front à l'est par le chemin public, du côté sud par l'emplacement de Monsieur Jos.St-Louis, du côté nord par l'emplacement de Monsieur Henri Therrien et en arrière à l'ouest par le résidu dudit lot 28A-1 appartenant à Jules Lauzon; Avec maison à deux logements et dépendances y érigées; Et tel que le tout se trouve présentement que l'acquéreur déclare connaître et dont il se dit satisfait.\u2022 Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Terrebonne, situé chambre 106, Palais de Justice, 400, rue Laviolettc, Saint-Jérôme, JEUDI le DIX-SEPTIÈME jour de JANVIER 1974 à DIX heures de l'avant-midi Le ahêrif adjoint.Bureau du Shérif, Gabhieli.k Fournelle.Saint-Jérôme, le 7 décembre 1973.55185 TERREBONNE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal j CANADA FLOORING LIMI-No.05,004,920/73.< v> TED.a corporation legally v incorporated having its head office and its principal place of business in the City and District of Montreal, plaintiff, va MARCEL MASSE, residing and domiciled in Pointe-aux-Trembles, District of Montreal, defendant.The immoveable hereinafter described and belonging to the defendant, to wit: \"An emplacement known and described under number three hunderd twenty-two of the official subdivision of block C (Block C-322) of the Township of Howard, Argenteuil Registration Division.With the buildings erected thereon.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable.To be sold at the Argenteuil County Registry Office, located at 430 Grâce Street, Lachute, P.Q., on TUESDAY, the FIFTEENTH day of JANUARY, 1974, at TWO o'clock, in the afternoon.Jean-Louis Muir, Sheriff's Office.Sheriff.St.Jérôme, December 3, 1973.55143 Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Terrebonne (/-lENTRE D'ALUMINIUM DE No.16.514A ^ MONTREAL LTEE, corporation v duly constituted, having its principal place of business in the Citv and District of Montreal, plaintiff, va Dame HERVÉ BÉLANGER, residing and domiciled at Lac-Carré, District of Terrebonne, defendant.The immoveable hereinafter described : \"A plot of land forming part of lot number one of the official subdivision of original lot number twenty-eight \"A\" (28A-Pt.1) in Range Seven (VII), of the Township of Wolfe, on the cadastre of said Township; Said plot of land measuring fifty feet (50') in width from north to south by seventy-five feet (75') in depth from east to west: Said plot of land hounded, in front on the east by the public road, on the south side by the emplacement of Mr.Jos.St-I.ouis, on the north side by the emplacement of Mr.Henri Thcrrien and at the rear on the west by the remainder of said lot 28A-1 belonging to Jules Lauzon; With a two-apartment house and dependencies erected thereon; As the whole now subsists and as the purchaser declares be to his knowledge and satisfaction.\" To be sold at the Terrebonne Division Registry Office, located in Room 106, in the Court House, 400 I^violette Street, St.Jérôme, on THURSDAY, the SEVENTEENTH day of JANUARY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.G abri elle Fournelle, Sheriff's Office.Aaaiatant Sheriff.St.Jérôme.December 7, 1973.55185 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, «° 50 7475 Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Princeville Avis est par les présentes donné que l'immeuble ci-dessous décrit, situé dans la Ville de Princeville, sera vendu à l'enchère publique, en la Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville sise au 25 St-Jacques ouest, le JEUDI DIXIÈME jour de JANVIER 1974.à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant la vente.City of Princeville Notice is hereby given that the property described hereinunder, situated in the City of Princeville, will be sold by public auction, in the City Hall of the City of Princeville, situated at 25 St-Jacques St.West.\" on THURSDAY, the TENTH day of JANUARY 1974.at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the paiement of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale.\tNom du propriétaire Xante of proprietor\t\tCadastre \t\t.P.64-94\t « Un terrain de figure irrégulière, situé au Village de Princeville, comté d'Arthabaska, du côté nord-ouest du chemin du 10e rang du canton de Stanfold, connu et désigné au cadastre officiel du Village de Princeville.comme étant une partie de la subdivision numéro quatre-vingt-quatorze du lot originaire numéro soixante-quatre (Ptie 64-94) mesurant en front, au sud-est 150 pieds pour avoir en arrière, au nord-ouest 120 pieds par une profondeur de 100 pieds perpendiculaire au chemin, et borné comme suit: en front, au sud-est par le chemin du 10e rang, du côté ouest par une partie du lot No 88-5 du même cadastre appartenant à Jules Roux ou ses représentants, en arrière au nord-ouest de même que du côté nord-est par une autre partie dudit lot No 64-94 appartenant à Emile Gagnon ou ses représentants sans bâtisse dessus.» En foi de quoi, j'ai signé ce présent document ce 29 novembre 1973.\"An emplacement of irregular figure, situated in the Town of Princeville.Arthabaska County, on the northwest side of the road of the 10th.range of the Township of Stanfold, known as being part of the lot number 64 of the subdivision of the lot number 94 (P.64-94) according to t«.e official cadastre of the Town of Princeville, measuring one hundred fifty feet (150 ft.) to the southeast so to have one hundred twenty feet (120 ft.) to the northwest with one hundred feet (100 ft.) depth perpendicular to-the road, bounded to the southeast by the road of the 10th range, to the west by a part of the lot number 88-5 of the same cadastre property of Jules Roux or his representatives, to the northwest as to the northeast by another part of the said lot number 64-94, property of Emile Gagnon or his representatives.\" In testimony whereof, I have signed this present document, this 29th day of November 1973.55079-49-2-o Le secrétaire-trésorier, FERNAVn Poiré.55079-49-2-o Ferxaxd Poiré, Secretary-Treasurer.Cité de Beaconsfield Avis public est par les présentes donné par le soussigné, Allen Mainville, Secrétaire-trésorier de la cité de Beaconsfield, que les immeubles ci-dessous désignés seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, VENDREDI, le ONZIÈME jour de JANVIER 1974.à DIX heures de l'avant-midi.pour satisfaire au paiement des taxes municipales générales, taxes scolaires, des intérêts, tel qu'indiqué plus bas, et des frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient réglés avant cette date à l'Hôtel de Ville, 303 boulevard Beaconsfield, Beaconsfield.Québec.City of Beaconsfield Public notice is hereby given by the undersigned.Allen Mainville, Secretary-Treasurer of the City of Beaconsfield, that the immoveable properties hereinafter described, will be sold by public auction at the Citv Hall, 303 Beaconsfield Boulevard, Beaconsfield.Quebec, on FRIDAY, ELEVENTH day of JANUARY 1974, at TEN o'clock a.m., for the payment of general municipal taxes, school taxes and interest, as given below, and the costs which may be subsequently incurred, unless before that date, the said taxes, interest and costs have been paid at the City Hall, 303 Beaconsfield Boulevard.Beaconsfield, Québec. 7476 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 CADASTRE DE LA PAROISSE DE POINTE-CLAIRE CADASTRE OF THE PARISH OF POINTE-CLAIRE No du Noms des No de Taxes Taxes Taxes rôle propriétaires cadastre municipales scolaires Intérêt totales Roll Properly Cadastre Municipal School Total No.Owner No.Taies Tares Interest Taxes 31503 F.Sealia Co.Ltd.27-1-3,2-3.2-5 $1,318.86 804.07 189.66 S2.312.59 re: Beaurepaire Drive 8501 Mr.F.Davies 8 partie / Pari 947.69 531.58 173.49 1.651.76 re: 437 Beaconsfield Blvd.La Commission municipale de Québec a, le lie jour de septembre 1973.autorisé une enumeration abrégée.Donné à Beaconsfield.Québec, ce quatrième jour de décembre 1973.Le secrétaire-trésorier.55155-50-2-o Allen Mainville.The Québec Municipal Commission has.on September 11, 1973.authorized a summarized description.Given at Beaconsfield.Québec, this fourth day of December 1973.Allen Mainville.55155-50-2-o Secretary-Treasurer.Ville Mercier Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la Ville de Mercier, seront vendus à l'enchère publique à la Salle du Conseil, 4 Rue Faubert, Mercier.LUNDI, le QUATORZIÈME jour de JANVIER 1974 à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente.La Commission municipale de Québec a autorisé une enumeration abrégée des numéros cadastraux en date du 26 novembre 1973.Town of Mercier Public notice is hereby given that the properties described hereunder, situated in the Town of Mercier, will be sold by public auction, in the Council Hall, 4 Faubert Street.Mercier, on MONDAY, the FOURTEENTH day of JANUARY 1974, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incured, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.The Québec Municipal Commission has authorized an abridged form of cadastral numbers on the 26th of November 1973.Noms des propriétaires No du cadastre Total A ames of proprietors Cadastral A o.Taxes\t munie.\tTaxes int.\tscol.et frais\tint.Munie,\t taxes\tSchool int.\ttaxes and costs\tint.S.Reich & Succ.,' Est.A.Reich.6-37, 7-22.S.Reich & Succ./ Est.A.Reich.6-38.S.Reich & Succ.' Est.A.Reich.6-39, 9-21 S.Reich & Succ.,' Est.A.Reich.6-40.9-10 Delbrooke Construction Inc.6-57.Delbrooke Construction Inc.6-61.Delbrooke Construction Inc.6-63.Delbrooke Construction Inc.6-70.S.Reich & Succ./ Est.A.Reich.6-75, 8-20.S.Reich & Succ.' Est.A.Reich.6-76.S.Reich & Succ./ Est.A.Reich.8-17.S.Reich & Succ./ Est.A.Reich.8-19, 6-74 .S.Reich & Succ./Est.A.Reich.9-11.S.Reich 40\t142-96.\t313\tn\t31\t33\t344\t65\t21.13\t0\t93\t22\tm.\t\t\t\t\t\t\t366.71 3-0-24\tKinguette, Gilles,\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t8867 Boul.I.die.Lasalle 680.\t142-98.\t304\t11\t39\t41\t433\t52\t82.79\t3\t73\t86\t52\t\t\t\t\t\t\t620.04 3-7-34\t\t142-79.\t403\t82\t40\t38\t444\tM\t37.14\t1\t72\t38\tso\t\t\t\t\t\t\t483.06 3-7-35\t.M\t142-80.\t58\t11\t5\tM\t64\t25\t36.09\t1\tus\t37\t77\t\t\t\t\t\t\t102.02 3-7-12\tCuthbertson, Blanche Mme-Mre.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t175 Bronsen Ave./1106,\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tOttawa, Kir 61-12, Ont.\t144-16.\t74\t'.m\t7\t49\t82\t3S\t\t\t\t\t\t.V.l\t40\tS\t94\t06\tM\t147.73 No fiche Roll Xo.3-7-50 3-8-19 3-8-20 3-17-18-1 6-3-36-7 6-51-20 3-19-12 3-28-40 3-38-35 3-38-37-1 3-38-38-1 3-38-39-1 3-112-1 3-112-2 3-112-12 3-112-13 3-112-14 3-43-5 3-46-20 3-46-27-1 3-46-27-2 3-46-27-3 3-46-27-4 3-46-33 3-46-37 3-133-2 3-79-293 3-79-300 3-82-1-1 3-112-50 3-115-27 3-115-28 3-115-29 3-115-30 3-126-2 3-126-3 3-126-5 Nom et adresse Xame and address Sachetti.Roberto.2144 Beaconsfield, Mtl 261.Gurewicz.C, 903 Alexis-Ninon, Ville St-Laurent 378.United Dev.Corp., 3510 St-Joseph est, Mtl 405.St-Georges, J.-Guy, 401 est, Boul.St-Joseph.Mtl 170.Prudential Dev.Inc., 5250 Ferrier.Ch.806, Mtl 308.Szentis, Zoltan, 500 Bedard.Lasalle 650.Anderson, John, Greenfield Sandra.1255 Carré Philips, (911, Mtl____ Mine-Mrs.Julien Desneiges, 84 St-Ferdinand.Chat-Centre.Fernand Murphy Const.Inc., C.P.146, Chateauguay.Kateri Realty Inv.557 Vouville, Chat-Centre.Klis, Walter.56 Wilbrod, Chat-Centre Tedeschi, Nicola, 118 Ste-Marguerite, Chat-Centre.Leon Freidman.Es-Quai., 50 Crômazie O-, (1009, Mtl 354.No du cadastre Cadastral number\tTaxes munie.M unie, taxes\t\tInt.\t\tTotal\t\tTaxes scol.cath.Cath.school taxes\t\tInt.\t\tTotal\t\tTaxes scol.prot.Prot, school taxes\t\tInt.\t\tTotal\t\tGrand total Great Mai \tS\t\tS\t\tT\t\tS\t\t«\t\tS\t\tS\t\tS\t\t8\t\tS 142-75.\t59\t18\t5\t91\t65\t110\t56\t\"7\t4\t23\t60\t30\t\t\t\t\t\t\t125.39 141-95.\t690\tus\t69\t03\t759\t41\t\t\t\t\t\t\t52\t43\t10\t40\t62\tS3\t822.24 141-96.\t691\t10\t69\t11\t760\t21\t\t\t\t\t\t\t52\tS'.l\t10\t60\t63\t10\t823.70 P-138.\t71\t72\t7\t17\t78\tso\t16\t02\t0\t7-1\t16\t70\t3\t34\t0\t15\t3\t¦III\t99.14 121-262.\t598\t42\t59.84\t\t658\t26\t197\t95\t9\tis\t207\t13\t80\t31\t4\t02\t84\t30\t949.75 119-P-331.\t6\t15\t0\t61\t6\t76\t\t\t\t\t\t\t0\t7'.l\t0\t05\t0\ts-l\t7.60 141-363.\t54\t20\t5.42\t\t59\t62\t30\t49\t1\t10\t31\tsu\t\t\t\t\t\t\t91.51 P-144.\t717\t01\t71\t70\t788\t71\t122\t02\t11\t33\t133\t05\t61\tS3\t10\t\u202210\t62\t23\t984.89 150-76-77.\t384\t91\t38\t10\t423\t111\t\t\t\t\t\t\t34\t68\t3\t¦15\t38\t03\t401.43 150-567.\t698\toi\t69\tsi;\t768\t17\t65\t59\t4\tOS\t70\t57\t18\tsi\t1\tss\t20\tO'.l\t859.73 150-568.\t710\t0 1\t71\tno\t781\tIII\t60\t23\t4\t70\t64\tO'.l\t16\t3,0\t1\t113\t17\t'.III\t864.02 150-569.\t709\tos\t70\ton\t780\t0 1\t60\t111\t4\t75\t64\t0!\t16\t30\t1\t03\t17\tll'.i\t863.87 150-484.\t1,108\t1!\t110\t81\t1,218\t115\t24\t96\t1\t33\t26\t20\t10\t46\t1\t05\t11\t51\t1,256.75 150-538.\t665\tS7\t66\t68\t732\t\u202215\t31\t50\t1\tss\t33\t47\t11\t00\t1\t17\t12\t86\t778.78 150-495.\t419\t32\t41\t93\t461\t25\t10\t27\t0\t46\t10\t73\t6\tS7\t0\tOS\t7\t55\t479.53 150-496.\t419\t01)\t41\t'.10\t461\t50\t10\t27\t0\t\u202210\t10\t73\t6\t^7\t0\tOS\t7\t55\t479.84 150.497.\t418\t21\t41\ts 2\t460\t110\t10\t27\t0\t46\t10\t73\t6\tS7\t0\tOS\t7\t55\t478.34 154-5.\t1,000\t01\t100\t(III\t1,100\t'.il\t59\t115\t2\tso\t61\t85\t\t\t\t\t\t\t1.162.76 158-11.\t391\t10\t39\t1 1\t430\t21\t138\t20\t6\t63\t144\tS 2\t55\t29\t2\t75\t68\t111\t633.07 157-37.\t255\t02\t25\t50\t281\tIS\t19\t44\t0\t93\t20\t37\tS\tno\t0\t25\t5\t31\t306.86 157-36.\t104\t12\t10\t\u2022Il\t114\tS3\t19\tII\t0\t113\t20\t37\t3\t90\t0\t20\t4\tIII\t139.00 157-35, 158-34____\t104\t12\t10\t11\t114\t53\t19\t\u202211\t0\t'.13\t20\t37\t3\t'.10\t0\t211\t4\t111\t139.00 158-33, 157-34____\t104\t12\t10\t\u202211\t114\t53\t19\t44\t0\t93\t20\t37\t3\t22\t0\t10\t3\t3 s\t138.28 P-158.\t56\t.s;,\t5\tlis\t62\t53\t4\t59\t0\t10\t4\t69\t0\t'.15\t0\t05\t1\tOil\t68.22 158-25.\t389\t70\t38\t07\t428\t70\t137\t74\t6\tno\t143\tso\t\t\t\t\t\t\t572.56 P-156.P157, P158.\t1,792\t2!\t179\t22\t1,971\t46\t1,236\t7S\t66\t02\t1.292\t80\t255\t07\t12\tso\t268\t77\t3,533.03 152-P377.\t309\tO.l\t30\t110\t340\t50\t494\t94\t55\t17\t550\t11\t\t\t\t\t\t\t890.70 152-P378.\t408\t70\t40\t87\t449\t66\t842\t53\t91\t18\t933\t71\t\t\t\t\t\t\t1,383.37 P-176.\t12\t53\t1\t25\t13\t78\t14\t46\t1\t12\t15\t58\t\t\t\t\t\t\t29.36 150-528.\t485\t27\t48\t52\t533\t79\t75\t66\t5\t00\t80\t66\t\t\t\t\t\t\t614.45 139-184.\t348\t88\t34\tss\t383\t70\t15\t21\t0\t70\t15\t91\t\u202217\t27\t9\t¦10\t56.67\t\t456.34 139-185.\t334\t72\t33\t\u202217\t368\tHI\t31\t20\t1\t44\t32\t64\t51\t86\t10\t40\t62\t26\t463.09 139-186.\t334\t72\t33\t47\t368\t19\t31\t20\t1\t44\t32\t64\t65\t22\t13\t02\t78\t24\t479.07 139-187.\t332\t63\t33\t25\t365\t7 s\t29\t58\t1\t¦10\t30\t98\t47\t24\t9\t41\t56\t65\t453.41 139-156.\t707\t05\t70\t70\t777\t75\t162\t66\t7\t46\t170\t12\t67\t60\t13\t42\t81\t02\t1,028.89 139-157.\t286\t53\t28\t65\t315\t18\t7\t75\t0\t15\t7\t90\t5\t41\t0\t27\t5\t68\t328.76 139-159.\t286\t63\t28\t65\t315\tis\t9\t04\t0\t46\t9\t50\t6\t41\to\t27\t6\t.68\t330.36 \tLeon Freidman, Es-Qual.,\t\t \t50 Crémazie O.#1009.Mtl 354.\t139-160.\t286 3-126-7\t\"\t139-161.\t286 3-126-8\t\t139-162.\t286 3-126-9\t\" \"\t139-163.\t286 3-126-12\t\" '¦\t139-166.\t354 3-126-13\t\t139-167.\t342 5-37-18\t\" \"\t249-301.\t527 5-39-5\t\" \"\t249-354.\t369 3-130-2\tValley Machinery Corp'n Ltd.\t\t \t336A St-Jean-Baptiste, Mercier.\t2-14, 1-9.\t2,092 4-10-7\tLa Grotta Armando,\t\t \t286 Earlscourt, Toronto, Ont.\t223-111.\t411 4-10-11\tHego Anselnio.606 Dundas Street\t\t \tWest.Toronto.Out.\t223-115\t416 4-16-12\t\t223-116.\t416 4-19-1\t\t223-127.\t17 4-19-2\t\t223-128.\t17 4-19-3\t\" \"\t223-129.\t17 4-18-4\tLinkonas Diminika.\t\t \t210, 2e Ave, Lasalle 690.\t224-204.\t373 4-24-5\tHehelo Manuel,\t\t \t28 Alma Ave.Toronto.Ont.\t223-194.\t19 4-24-6\tn ii\t223-195.\t18 5-7-37\tHébert.Paul.C.A., Es-Qual.\t\t \t500 Place D'Armes, Mtl 126.\t248-38-37-3-2-1.\t3.969 5-8-23\tMarchand, Guy,\t\t \t\t250-3.\t405 5-7-89\tDepositors Mortgnge Corp.,\t\t \t1242 Peel.Mtl 110.\t248-P188.\t70 5-7-90\ti.\t248-P189.\t70 5-7-91\t.,.\t248-P190\t70 5-7-92\t.,\t248-P191.\t68 5-7-93\t\t248-P192.\t72 5-7-94\tm\t248-P193.\t72 5-7-95\tn\t248-P194.\t71 5-7-96\t.\t248-P195.\t69 5-7-99\t\" \"\t248-P224.\t89 5-7-100\t\" \"\t248-P226.\t78 5-7-105\t\t248-231.\t46 5-17-24\t\t248-343.\t316 5-17-25\tii .\t248-344.\t316 5-17-46\t\" \"\t248-364.\t331 5-17-47\ti.\t248-365.\t319 5-17-48\tii ,,\t248-366.\t314 5-17-49\t\" \"\t248-367.\t687 5-17-51\t\"\t248-319.\t731 5-17-52\tii\t248-318.\t331 5-17-53\t\" \"\t248-317.\t329 5-17-54\t\t248-316.\t325 5-17-55\t\t248-315.\t321 5-17-67\tn ii\t248-304.\t536 5-17-68\t\" \"\t248-303.\t320 5-17-79\t\t248-292.\t334 5-18-25\t\"\t248-125.\t530 5-18-26\t\t248-124.\t492 5-19-12\t\t248-126.\t502 5-19-25\t\t248-265.\t718 5-21-2-1\t\t248-P281, 248-P282\t93 5-21-3\t\t248-280.\t593 53\t28\t66\t315\t18\t9\t01\t0\t46\t9.50\t5.41\t\t0.27\t5.68\t330.36\t 53\t28\t66\t315\t18\t26\t10\t1\t21\t27.31\t18\t.47\t1.85\t20.32\t362.81\t 53\t28\t66\t315\t18\t26\t11\t1\t21\t27.31\t17\t.59\t1.76\t19.35\t361.84\t 53\t28\t05\t315\t18\t26\t1(1\tI\t21\t27.31\t17\t.59\t1.76\t19.35\t361.84\t 98\t35\t49\t390\t47\t15\t22\t0\t70\t15.92\tIS\t.86\t1.87\t20.73\t427.12\t 59\t34\t25\t376\t84\t14\t14\t1\t08\t15.22\tIS\t63\t1.86\t20.49\t412.55\t OS\t52\t79\t580\t77\t84\t00\t5\t76\t90.75\t26\t93\t2.69\t29.62\t701.14\t 2S\t36\t02\t406\t20\t55\t84\t4.08\t\t59.92\t16.84\t\t1.68\t18.52\t484.64\t OU\t209\t20\t2,302\t19\t140\t18\t6\t53\t146.71\t58\t02\t2.90\t60.92\t2,509.82\tft \"¦a 23\t41\t12\t452\t36\t57\t20\t4\t37\t61.57\t\t\t\t\t513.92\tft 04\t41\t00\t457\t64\t39\t55\t1\t86\t41.41\t\t\t\t\t499.05\tC: 01\t41\t60\t457\t01\t39\t55\t1\t86\t41.41\t\t\t\t\t499.05\t 28\t1\t72\t19\t00\t10\t03\t0\t46\t10.49\t\t\t\t\t29.49\t 28\t1\t72\t19\t00\t10\t03\t0\t46\t10.49\t\t\t\t\t29.49\t 30\t1\t73\t19\t03\t11\t59\to\t61\t12.10\t\t\t\t\t31.13\t 82\t37\t38\t411\t20\t10\t87\t0\t48\t11.35\t\t\t\t\t422.55\ti 39\t1\t93\t21\t32\t13\t02\t0\t60\t13.62\t\t\t\t\t.34.94\t 84\t1\t88\t20\t72\t12\t66\to\t56\t13.22\t\t\t\t\t33.94\tto 53\t396\t05\t4,366\t48\t3,437\t67\t15S\t72\t3,596.39\t\t\t\t\t7,962.87\t 06\t40\t50\t445\t56\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t445.56\t1 83\t7\tOS\t77\t91\t58\t77\t2\t80\t61.57\t27\t17\t2.71\t29.88\t169.36\tCo r> 02\t7\t00\t77\t68\t58\t77\t2\t80\t61.57\t27\t17\t2.71\t29.88\t169.13\tS 54\t7\t05\t77\t59\t58\t77\t2\t80\t61.57\t27\t17\t2.71\t29.88\t169.04\t 83\t6\t88\t75\t71\t58\t77\t2\tSO\t61.57\t27\t17\t2.71\t29.88\t167.16\t 31\t7\t23\t79\t64\t60\t61\t2\t86\t63.46\t28\t03\t2.80\t30.83\t173.83\t 09\t7\t20\t79\t20\t60\t61\t2\t85\t63.46\t28\t03\t2.80\t30.83\t173.58\t& 87\t7\tis\t79\t05\t60\t61\t2\t85\t63.46\t28\t03\t2.80\t30.83\t173.34\t 46\t6\t04\t76\t40\t58\t77\t2\tso\t61.57\t27\t17\t2.71\t29.88\t167.85\t 13\t8\t91\t98\t04\t77\t90\t3\t69\t81.49\t36\t03\t3.60\t39.63\t219.16\t5- 91\t7\tSO\t86\tso\t65\t95\t3\t(13\t68.98\t30.48\t\t3.05\t33.53\t189.31\t 56\t4\t05\t51\t21\t88\t54\t4\t10\t92.64\t40\t95\t4.09\t45.04\tlss.so\tKi 15\t31\t01\t347\t70\t34\t67\t1\t58\t36.25\t15.99\t\t1.60\t17.59\t401.60\tto 15\t31\t01\t347\t70\t34\t67\t1\t58\t36.25\t15\t00\t1.60\t17.59\t401.60\t 41\t33\t14\t364\t66\t43\t75\t2\t(10\t45.75\t20\t18\t2.02\t22.20\t432.50\t 32\t31\t93\t351\t25\t40\t82\t1\tSO\t42.68\t18\t81\t1.88\t20.69\t414.62\t*-* 79\t31\t¦17\t346\t20\t39\t75\t1\tS 2\t41.57\t18\t33\t1.83\t20.16\t407.99\t 15\t68\t71\t755\tSO\t48\t81\t2\t21\t51.05\t22\t50\t2.25\t24.75\t831.66\t (111\t73\t10\t804\t10\t52\t82\t2\t\u202212\t55.24\t24\t34\t2.43\t26.77\t886.11\tft 91\t33\t19\t365\t10\t43\t77\t2\t00\t45.77\t20\t18\t2.02\t22.20\t433.07\t3 21\t32\t92\t362\t13\t41\t35\t1\t91\t43.26\t19\t07\t1.91\t20.98\t426.37\t 45\t32\t54\t357\t00\t38\t94\t1\t77\t40.71\t17\t03\t1.79\t19.72\t418.42\t 28\t32\t12\t353\t40\t36\t28\t1\t68\t37.96\t16\t70\t1.67\t18.37\t409.73\t 01\t53\t00\t589\t61\t37\t30\t1\t72\t39.08\t17\t22\t1.72\t18.94\t647.63\t\u2022 31\t32\t03\t352\t31\t37\t30\t1\t72\t39.08\t17\t22\t1.72\t18.94\t410.36\ta 88\t33\t¦IS\t368\t30\t37\t02\t1\t72\t39.34\t17\t33\t1.73\t19.06\t426.76\t IS\t53\t(II\t583\t10\t52\t28\t2\t¦12\t54.70\t24\tOS\t2.41\t26.49\t664.38\t 54\t49\t25\t541\t79\t44\t75\t2\t05\t46.80\t20\t05\t2.06\t22.71\t611.30\t 19\t50\t21\t552\t40\t50\t67\t2\t33\t53.00\t23\t30\t2.34\t25.70\t631.10\t 62\t71\t85\t790\t37\t39\t48\t1\tSO\t41.34\t18\t19\t1.82\t20.01\t851.72\t 25\t9\t32\t102\t67\t21\t51\t0.98\t\t22.49\t4\t45\t0.20\t4.65\t129.71\t 49\t59\t34\t652\t83\t39\t77\t1\t86\t41.63\t18\t33\t1.83\t20.16\t714.62\t Ni.fiche Roll An.5-21-4 5-21-5 5-21-6 5-21-7 5-21-8 5-21-9 5-21-10 5-21-11 5-21-12 .'.-'I 14 5-21-15 5-21-16 5-23-1 5-23-2 5-23-3 5-23-4 5-23-5 5-23-6 5-23-7 5 23 S 5-23-9 5-23-10 5-23-11 5 23-12 5-23-13 5-23-13-1 5-24-2 5-24-3 5-24-4 5-24-5 5-24-6 5-24-7 5-24-8 5-24-9 5-24-10 5-24-11 6-24-12 5-24-13 5 21 14 21 15 4 24 16 5-24-17 5-24-18 5-24-19 5-24-20 5-24-21 5-24-22 5-24-35 Nom et adresse .\\amr ami address Depositors Mortage Corp 1242 Peel.Mtl 110.No du cad:ist rc Cadastral number 248-279.248-278.24S 277 248-276 248-275 .248-274.248-273 248-272 248-271.248-269 248-268.248-267.248-429 .248-428.248-427.248-426.248-425.248-424.248-423.248-422.248-421.248-420 .248-419 248-418 .248-417.248-416 .248-433 .248-P432 248-431 248-130 248-401.248-100 248-399 248-398.248-397.248-396 .248-395 .248-394 .248-393.248-392 248-391 .248-390 248-389 248-388.248-387.248-386 .248-P-385 248-P228.Taxes munir.Munie, lares\t\tInt.\t\tTotal\t\tTaxes scol.cath.Calh.school laies\t\tInt.\t\tTotal\t\tTaxes scol.prot.l'rol.school laies\t\tInt.\t\tTotal\t\tGrand total Orrai Mal »\t\t1\t\tS\t\t*\t\t8\t\tt\t\tS\t\t8\t\tS\t\t« 603\t1.7\t50\t36\t554\t03\t34\tos\t1\t68\t36\t66\t16\tlo\t1\t1.1\t17\t71\t608.30 503\t1.7\t50\t36\t554\t03\t34\tos\t1\t68\t30\t66\t16\t10\t1\t01\t17\t71\tnos 3o 608\t67\t60\t31-,\t554\t(13\t34\tOS\t1\t5S\t36\t66\t16\t10\t1\t61\t17\t71\t608.30 608\t67\t5(1\t36\t554\t03\t34\t98\t1\t5s\t36\t86\t16\t10\t1\t01\t17\t71\t608.30 608\t67\t5(1\t31,\t554\t03\t34\tos\t1\t68\t36\t56\t10\t111\t1\t61\t17\t71\t0118 311 503\t1,7\t50\t30\t554\t03\t34\tOS\ti\t5s\t36\t50\t16\t10\t1\ti.l\t17\t71\t608.30 608\t1,7\t50\t30\t554\t03\t34\tos\t1\t68\t30\t5o\t16\t10\t1\t01\t17\t71\t608.30 608\t1,7\t50\t30\t554\t03\t34\tos\ti\t5s\t36\t50\t16\tIII\t1\t01\t17\t71\tnos 30 608\t1,7\t50\t36\t554\t03\t34\tOS\tl\t5s\t36\t66\t16\t10\t1\tol\t17\t71\tnos 3.0 503\t1,7\t50\t36\t554\t113\t34\tOS\t1\t5-\t36\t50\t16\tKl\t1\t1.1\t17\t71\t608.30 503\t1.7\t5(1\t30\t554\t03\t34\tOS\t1\t5-\t36\t50\t16\t1(1\t1\t01\t17\t71\t608.30 608\t1,7\t50\t30\t554\t03\t34\tos\tl\t68\t36\t50\t10\tlo\t1\ttu\t17\t71\t608 30 12\t10\t1\t24\t13\t73\t15\t01,\t0\t7(1\t16\t00\t7\t38\t0\t74\ts\t12\t38.51 18\t75\t1\t37\t15\t12\t17\t55\t0\t70\t18\t3 1\t8\t10\t0\tM\t8\t91\t42.37 14\t50\t1\t15\t16\t04\t18\t62\t0\tM\t19\tlo\t8\t61\t11\t86\t9\t47\t4 1 07 11\t50\t1\t15\t16\t0 1\t18\t62\t0\tM\t19\t46\t8\t61\t0\t86\t9\t47\t44 97 11\t50\t1\t46\t16\t0 1\t18\t62\t0\tSI\t19\t46\t¦s\t61\t0\tsu\t9\t47\t44.97 14\t50\t1\t15\t16\t01\t18\t1,2\t0\tSI\t19\t46\t8\t61\t0\tSI,\t9\t47\tIl 07 14\t50\t1\t46\t10\tIII\t18\t02\t0\t84\t19\tK,\t8\t61\t0\t80\t9\t47\t44.97 14\t50\t1\t45\t16\t04\t18\t62\t0\tN4\t10\tK,\tH\t01\t0\tSO\t9\t47\t44.07 14\t50\t1\t45\t16\t01\t18\t02\t0\t84\t19\tH,\tX\t01\t0\tSI,\t9\tIV\t44 07 14\t511\t1\t15\t16\t04\t18\t02\t0\tSI\t19\t46\t8\t01\t0\t86\t9\t47\t44.97 14\t50\t1\t45\t16\t04\t18\t62\t0\t84\t19\t46\t8\t61\t0\tso\t9\t47\t44.97 14\t50\t1\t45\t16\t04\t18\t02\t0\tsi\t10\tlo\ts\t61\t0\tso\t9\t47\t44.97 14\t5(1\t1\t15\t16\t04\t18\t1.2\t0\tSI\t19\t40\t8\t61\t0\tso\t9\t47\t44.97 i des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis d'annulation de lettres patentes (1er avis), de la compagnie « DUROC.RAPH INTERNATIONAL LIMITED .paru dans la Gazette officielle du 25 août 1973.numéro 34.à la page 4950.en y remplaçant partout où apparaissait ledit nom.le mot « DURO-GRAPII- par le mot « Dl'ROGRAF de manière que le nom de la compagnie se lise ainsi: « Dl'ROGRAF INTERNATIONAL LIMITED ».Le directeur du serrice des compagnies.Pierre Desjardins.->.->! im )\u201e 12269-54 DUROGRAF INTERNATIONAL LIMITED Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives to correct the notice of annulment of letters patent (first notice), of \"DURO-GRAPH INTERNATIONAL LIMITED\", published in the Québec Official Gazelle, dated August 25.1973, issue number 34.on page 4950, by replacing therein wherever the said name appears, the word \"DURO-GRAPH\" by the word \"DUROGRAF\", so that the name of the Company niav read as follows: \"DUROGRAF INTERNATIONAL LIMITED\".Pierre Desjakiiins.Director of the Companies Service.550SO 12269-54 CAISSE POPULAIRE DE ST-JEAN .NOËL MARTIN CAM.18-001326-73 Edition numéro 49 du 8 décembre 1973.|>age 7323.le lieu de vente aurait dû se lire: « Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laprairie.à 214 St-Ignace.Leprairie » au lieu «le: \u2022 Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais «!«\u2022 Justice, en lu Ville «le Montréal.10 est.rue Craig.10e étage, chambre 56-, 55081 CAISSE POPULAIRE DE ST-JEAN vs NOËL MARTIN S.C.M.18-001326-73 In issue number 49.dated December 8.1973, on page 7323.the place of sale should have read as follows: \"To be sold at the County of Laprairie Registry Office, 214 St.Ignace, Laprairie\".instead of: \"To be sold at the Sheriff's Olfice.in the City of Montreal Court House.10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56\".5,5081 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105- année, n° 50 7485 INDEX No 50 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Alliance sécurité et investigation limitée.7430 Alliance Security and Investigation Limited.7430 Club Les Sans Peur inc.(LA3.).7429 Estate of Noël Bélanger (Benefit of Inventory).7428 Gamache Exploration & Mining Co.Ltd.(L.P.S.).7429 Parish of St.Mauricc-de-Thetfoid-Mines and Parish of St.Alphonse-de-Thetford-Mines (Limitschanged) 7429 Parish of Ste.Agnès-cie-Donnacona and Parish of St.Jean-Bapriste-des-Ecureuils (Limits changed).7429 Paroisse de Saint-Maurice de Thetford-Mines et Paroisse Saint-Alphonse de Thetford-Mines (Modification des limites).7429 Paroisse de Sainte-Agnès-de-Donnacona et Paroisse de Saint-Jean-Baptiste des Ecureuils (Modification des limites).7429 Succesion Ncël Bélanger (Bénéfice d'inventaire).7428 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Boffice, Marie Thérèse.7432 Boffice, Myriam.7432 Buda, Miklos.7432 Dossegger, Johann Rudolf.7431 Douillard.François Anatole.7430 Gazley, Raymond Alden.7431 Grandmaison, Joseph Gaétan Jacques.7431 Nagler, Maier.7430 O'Driscoll.Gerald.7431 Rioux, Marie Solange.7430 Rochon, Marie Nicole Suzanne.7431 Tremblay, France.'432 Walczewski, Alfred.7432 CAISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND Notice of decisions rendered.7390 ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS Notice of submission of application.7410 ,, .\u201e .i .t\\ i n, \u2022 Notice \"proprio motu\" by the Commission.7423 Caisse Populaire de Notre-Dame des Trois- Taxi, décision sur les taux et tarifs pour le Rmeres (La) ¦ .¦¦ \u2022 ¦ ¦ '426 ^ vé;,icuIe.taxi.z.7406 Caisse Populaire de St-Philippe (La) (Mod.Taxicab, decision en ratesand tariffs respecting terr.) .transport by taxicab.7406 Caisse Populaire du bacrc-l oeur de Jésus, Québec (La) (Mod.terr.).7427 d'affaires Places of Business Caisse d'économie des employés de la société ^ /g prm;llce: {\u201e the Province: d'aluminum Reynolds (Canada) limitée r (Nom\u2014Name ch).7426 Capital Coecli Line.7425 Caisse d'économie des services hospitaliers Delorme (Robert David ONeil).74^5 communs (Montréal) (Fusion).7427 Dennmg (Ivan) and Sons Enterprises Ltd.7425 Caisse Populaire Mauricienne de Shawinigan Gauthier Transport Enrg.1*40 (La) (Mod.terr.).7426 Gledhill (A.) & Sons Inc.7424 Joint Hospital Services Credit Union (Mont- Mac s Delivery Service.74^5 real) (A malgamation).7427 Quinn (T.B.) Truck Lines Ltd.742o ' Robert David O Neil Delormc.7525 COMMISSION COMMISSION Taligian (Georges).7424 Commission Québec Transport COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL des transports du Québec Commission ÉTRANGÈRES COMPANIES Avis de décision rendues.7390 changement d'agent: Change of agent: Avis de la Commission « proprio motu ».4^d .Avis d'introduction de requêtes.7410 Cast.ng Materials Western Hemisphere, Inc.,433 7486 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, Xo.50 COMPAGNIES - COUPAMES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter B & S Paper Products Inc.7387 Bordulac Inc.7387 Bowers (Lewis C.) and Sons (Québec) Ltd.7387 Bowers (Lewis C.) et Fils (Québec) Ltée.7387 Cercle St-Antoine Inc.7387 5600 Décarie Inc.7388 Cintilair Inc.7388 Clément (A.) Co.Limited.7388 Clément (A.) Cie Limitée.7388 Concorde Acceptance Inc.7388 Coro-Mar Realtv Inc.7388 Corona Brush Ltd.7388 Delco Transport Inc.7388 Duro Stone Ltd.7388 Ecole de sexologie île Montréal Inc.7388 Fleur de Lys Modem Homes Inc.7388 International Plastering Co.Ltd.Kres-Kno (Québec) Ltd.7388 Park Warehouse Ltd.7388 Changement de nom Change of name Entreprises Eniino Inc.(Les).7388 .lardins Québec (Les).7388 Marcoux (Gérard R.) Inc.7388 Material Handling Sociétv of Montreal .7388 Québec Gardens.7388 Société de Gestion îles Jardins Québec Inc.(La).7388 Société de Manutention de Montréal (La).7388 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Agences Baron ltée.7434 Baron Agencies Ltd.7434 Bédard (Roger) inc.7434 Bouchard (Yves) inc.7435 Bourgeois (Marcel) inc.7437 Braun (Québec) Limited.7439 Brien (Gérard) & Fils Inc.7437 Centre l-ocal de Santé St-Jacques Inc.7438 Commercial Property Developments Inc.7440 Distribution Vimont inc.7438 Ecole Saumurai de Karate et Judo inc.7435 F.surcn ( (instruction Corporation.7435 Evergreen Land Development Co.7438 Faubert (Ernest) ltée.7439 (iue-Mar Excavation Ltée 7440 Julien (E.L.) ltée.7435 Levesquc (R.O.) inc.7437 l.ittfam Investment Corporation.7437 Maçonnerie du St-Laurent ltée.7436 Marché d'alimentation M.C.M.ltée.7436 Marché Lisée ltée.7334 Mathieu (J.R.) ltée 7439 Mayfair Buildings Ltd.7435 l'atry Inc.7439 Phénix (Théo) ltée.7438 Placements Conrad Blanchet inc.(Les).7438 Read Buildings Snack Bar Ltd.7436 Richmount Investment Co.7436 Service mécanique de Québec inc.7437 Shaffran (Joseph) inc.7436 Toledo Auto Leasing Ltd.7439 Divers Miscellaneous Allpak (Québec) Limited (Dir.).7441 Allpak (Québec) limitée (Dir.).7441 Camp Familial Bleu et Blanc inc.(Dir.) 7441 Canexco inc.(Dir.).7442 Gar-lan Leasing (Québec) Ltd.(Dir.).7441 Ligues du hockev mineur de N.D.G.inc.(Dir.).7441 Location Gar-lan (Québec) ltée (Dir.).7441 Martin (J.B.) Company Limited (Dir.).7440 N.D.G.Minor Hockev Leagues Inc.(Dir.) .7441 Neveu & Neveu ltée.7440 Pouliot.Guérard & Associates Inc.7441 Pouliot.Guérard & Associés inc.7441 Société d'administration Dero inc.7441 Spancrete.Limited.7440 Société J.B.Martin limitée (La) (Dir.).7440 Lettre» patentes Letters Patent (\\\" partie) (Part I) Administration 2000 inc.7379 Aliments exotique de Montréal inc.(Les).7381 Aluminium L.G.R.inc.7379 Amusements Bellechasse inc.(Les).7379 Anjo Enterprises Inc.7381 Appareils électroniques M & M ltée.7382 Atelier d'usinage M.B.T.R.inc.7379 Atmor Inc.7379 Auto Cyclone inc.7379 Autobus Pelletier ltée.7379 Automobile G.F.inc.7379 Azores Hardware Inc.7379 Barnstorming Promotions Inc.7379 Batteries J.E.L.inc.7379 Bélrnd (Maurice) ltée.7379 Bellechasse Amusement Inc.7379 Belvicw Construction Company Inc.7379 Biochinm Industries Inc.7379 Bouthillier (Roger) inc.7379 Boutique Candide inc.7379 Brasserie du routier de Brossard inc.7379 Broco Inc.7379 O.K.Furniture Ltd.7379 C.L.I.Sales & Distributing Company Ltd.7380 ( adence Comics Publications Inc.7388 Campbell Garage Inc.7382 Canadian Fashion Sales Inc.7382 Carignan Transport Inc.7384 Casse-Croûte L.& P.inc.7379 Castel Laval Properties Ltd.7379 Caves Stc-Michelle limitée (Les) 7379 Centre d'informatique danger & Marsolais inc.7380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973.105' année, n° 50 7487 Lettres patentes Letters Patent (!'« partie) (Part I) (suite) (continued) Champagne & Guindon inc.7380 Charcuterie Etoile d'Or inc.7380 Château Xotre-Damc-du-Lac inc.7380 Chauffage Perfecta inc.7383 Circle Service Station Inc.7384 Comexa inc.7380 Communications Lang Edward inc.(Les).7382 Compagnie d'administration Prosper inc.(La) 7380 Compagnie de construction Belview inc.(La) 7379 Compagnie des ventes & distributions C.L.I.ltée (La).7380 Compagnie d'optique Kenwood ltée.7380 Confections Sarrazin et Frères inc.7380 Conkcl Enterprises Inc.7380 Construction Dufour & Tremblay inc.7380 Construction Fenman inc.7381 Construction Cilendale inc.7382 Construction H.M.R.Inc.7380 Construction Hermans Inc.7380 Construction Houle & Fils ltée.7380 Construction M.G.D.inc.7380 Construction Naples inc.7383 Construction Lafrenière ltée (Les).7380 Construction M.Gravel inc.(Les).7380 Corporation de construction Grand National 7380 Corporation M innés.7380 Corporation Xordev (La).7383 Corporation U.I.D.ltée (La).7384 fossette (.1.) Transport Ltd.7380 Coupes chevalines Mauriciennes inc.(Les).7380 Croteau (Edgar) inc.7380 Cyap Imports Ltd.7380 Cyclone Auto Inc.7379 D.O.M.Electric Inc.7380 Deschênes (J.C.) inc.7380 Dessinateurs métropolitains inc.7380 Dustributeurs Rose ltée.7384 Distribution B.D.F.M.inc.7380 Dogi inc.\u2022.7380 Domaine St-Sauveur-des-Monts inc.7381 Draperies LaSalle inc.7382 Duhamel Equipments Ltd.7381 Ecoter Inc.7381 Edifice F.M.Marcotte inc.7381 Edifices de l'avenue Letourneux inc.(Les).7381 Eldridgc Avenue Enterprises Inc.7381 Entreprises Anjo inc.7381 Entreprises avenue Eldridge inc.(Les) 7381 Entreprises Conkel inc.(Les).7380 Entreprises Cusson et Paulin ltée (Les) 7381 Entreprises d'électricité D.O.M.inc.7380 Entreprises Evac inc.(Les).7381 Enterprises G.K.W.inc.(Les).7381 Entreprises Grand Gousier inc.(Les).7381 Entreprises Guy Paquin inc.(Les).7381 Entreprises J.O.T.inc.(Les).7381 Entreprises J.P.Roy inc.(Les).7381 Entreprises José et Laurent inc.(Les).7381 Entreprises Maurice Longtin inc.(Les).7381 Equipements de stéréo Trans-Québec inc.(Les).7381 Equipements Duhamel ltée.7381 Erections Mirabel inc.(Les).7381 Excavation Gaétan Dion inc.7381 Excavation Guérin & Frères inc.7381 Exotic Foods of Montreal Inc.7381 Extermination Mochon inc.7381 Fautcux, Atkinson and Associates Inc.7381 Fauteux, Atkinson et Associés inc.7381 Fenman Construction Inc.7381 Ferme des Erables inc.7381 Fermes Mie ltée (Les).7383 Films Gilbert Gratton inc.(Les).7381 Flexform Sportswear Ltd.7381 G.K.W.Enterprises Inc.7381 Gagné (Denis) inc.7382 Gagné & Santerre inc.7381 Garage Campbell inc.7382 Garderie & Centre du Jour Métropolitain inc.7382 Gariépy (Georges) inc.(Correction).7484 Gauthier (Jean-Paul) & Fils inc.7382 Ginarche inc.7382 Glendale Construction Inc.7382 Gonthier (Lionel) inc.7382 Greater National Building Corporation.7380 (¦uérin & Brothers Excavation Inc.7381 Gutenberg Printer Inc.7382 H.I.M.Textiles Inc.7382 Habitat Val Orford inc.7382 Houle & Son Construction Ltd.7380 Immeubles Castel Laval ltée (Les).7379 Immeubles Cloumex inc.(Les).7382 Immeubles Kordzian inc.7382 Importation Tricorama inc.7384 Importations Cyap ltée.7380 Imprimerie Serge Housseaux inc.(Correction).7484 Imprimeur Gutenberg inc.7382 Indeco Ltd.7382 Indecoltée.7382 Industries Biochima inc.7379 Insertomatic Inc.7382 Investissements Chelmac inc.(Les).7382 Investissements Yenman ltée (Les).7384 Irleo Ltd.7382 Irléoltée.7382 J.E.L.Batteries inc.7379 Kenwood Optical Co.Ltd.7380 Kordzian Realties Inc.7382 L.G.R.Aluminium Inc.7379 Lafrance (Gérard) inc.7382 Lafrenière Construction Ltd.7380 Lang Edwards Communications Inc.7382 LaSalle Draperies Inc.7382 Letourneaux Avenue Buildings Inc.7381 Location d'autos Marcel Gauthier ltée.7382 Luck (Robert) Inc.7382 M.G.D.Construction Inc.7380 M & M Electronics Ltd.7382 Magasin Poulin inc.7382 7488 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part F) (suite) (continued) Maison de stylo Peel inc.(La).7382 Manufacture Neucliâtel inc.7382 Marché canadien de modes inc.7382 Marois (Harry) & Fils, inc.7382 Menuiserie Cebe inc.7382 Metropolitan Designers Inc.7380 Metropolitan Nursery & Day Centre Inc.7382 Meuble C.K.ltée.7379 Mia Farms Ltd.,.7383 Minnes Corporation.7380 Mirabel F.rectors Inc.7381 Miroflcctor (Canada) Limited.7383 Miroflector (Canada) limitée.7383 Mobilier éducationnel D.M.ltée.7383 Mochon Extermination Inc.7381 Modes Orent ltée (Les).7383 Mondor Radiators Inc.7383 Munroe (Maurice) & Ed.Ltd.7383 Munroe (Maurice) & Ed.ltée.7383 Nadeau (C.A.) & Fils inc.7383 Naples Construction Inc.7383 Natik Inc.7383 Nettoyeurs Rose inc.7384 Neucliâtel Mfg.Inc.7382 Nordev Corporation.7383 Orent Fashions Ltd.7383 P & B Discount Stores Ltd.7383 P.S.L.G.Productions Inc.7383 Papeterie R.C.inc.7383 Parelco inc.7383 Peel Pen Shop Inc.7382 Pellant (Jules) et associés inc.7383 Perfecto Heating Inc.7383 Pétrole J.M.& B.Dupont inc.7383 Photolithographic Artes inc.7383 Placements France Pierre inc.7383 Placements Pacifique-Sud ltée (Les).7384 Plage Jacques inc.7383 Produits sanitaires du Saguenay-Lac-St-Jean inc.(Les).7383 Productions P.S.L.G.inc.(Les).7383 Promotions Banstorming inc.7379 Prosper Management Co.Inc.7380 Publications Comiques Cadence inc.7383 Quincaillerie Azores inc.7379 Quincaillerie I).M.S.Paradis inc.7383 Racettc (.l.-P.) inc.7383 Radiateurs Mondor inc.(Les).7383 Raygeo ltée.7383 Reproduction A.R.T.inc.7383 Restaurant Au Pied du Mont inc.7383 Restaurant Galaxie ltée.7383 Restaurant La Gascogne inc.(Le).7383 Restaurant le Petit Québec inc.7384 Restaurants de l'Estrade inc.7384 Rose Cleaners Inc.7384 Rose Distributors Lid.7384 Roy (J.P.) Enterprises Inc.7381 Salois Tire Service Inc.7384 Sandales Orthobec inc.(Les).7384 Seigneurie de St-Lucicn inc.(La).7384 Service de pneus Salois inc.7384 Service d'escompte P.& B.ltée.7383 Shcfco limitée.7384 Solopic Ltd.7384 Solopicltée.7384 Sopcm inc.7384 Soucv & Demers limitée.7384 South Pacific Investments Ltd.7384 Stage Restaurants, Inc.7384 Station de service Rond-Point inc.7384 Tapis Mirabel inc.(Les).7384 Taverne Vincent inc.7384 Textiles H.I.M.inc.7382 Transport Carignan inc.7384 Transport J.Cossette ltée.7380 Transport M.Juneau inc.7384 Transport Marc A.Tremblay ltée.7384 Trans-Québec Stereo Equipment Inc.7381 Tricorama Import Inc.7384 Troiano (Joe) Inc.7384 U.I.D.Corporation Ltd.7384 Variétés St-Jacques inc.7384 Vergers Valmont inc.(Les).7384 Vero inc.7384 Véronneau & Fils ltée.7384 Vêtements de sport Flexform ltée (Les).7381 Viau (Bernard J.) inc.7384 YYireco Ltd.7384 Wirecoltée.7384 Venman Holdings Ltd.7384 Zazette inc.7384 Lettres patentes Letters Patent (3' partie) (Pari 17/) Association d'anciens combattants Sc.muel de Champlain.7385 Association de Madclinots Escouade des Iles 7385 Association des citoyens de Montréal Ouest 7385 Association des Hommes d'Affaires de La Tuque Inc.7385 Atelier du Meuble Centre-Sud Inc.7385 Ateliers d'Education Populaire de Mercier 7385 Club de Motoneige Les Voies Rapides Inc.7385 Club de Plongée Sous-Marine Subaquabec Inc.7385 Club des Jeunes Handicapés du Saguenay Inc.(Le).7385 Club Les Sans Peur inc.7429 Club Lions de La Pocatière Inc.7385 Club Moto-Neige Escapade.7385 Club Sportif Les Précurseurs de Stc-Anne-de- Beaupré Inc._.7385 Comité de Citoyens de La Vallée île La Lièvre 7385 Comité de Démocratisation Notre-De.me des Neiges.7385 Comité Inter-Communautairc du Comté de Roberval Inc.7385 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7489 Lettres patentes (3\" partie) (suite) Letters Patent (Part III) (continued) Comité Organisateur des Jeux d'été du Trois-Rivières Métropolitain (Le).7385 Community Rights on Social Services C.R.O.S.S.7385 Concord Polish Roman Catholic Society.7386 Editions Spirisphère Inc.(Les).7385 Carde St-Adalbert de l'Islet Inc.7385 Carde St-Damase Inc.7385 Garde St-Honoré Inc.7385 Garde St-Paulin Inc.7385 Garde St-Pierre du Sud de Montmagny Inc.7385 Garde St-Ulrie de Matane Inc.'.7385 Garde Ste-Ursule Inc.7385 Garderie Saint-Urbain.7385 Institut d'Assurance de l'Est du Québec (L') 7385 Insurance Institute of Eastern Québec (The) 7385 Montreal West Citizens' Association.7385 Samuel de Champlain War Veterans Association .7385 Services Sociaux sur les droits des Citoyens C.R.O.S.S.7385 Société d'Expansion de Rimouski Inc.7386 Société Polonaise Catholique Romaine Concorde.7386 Union des Assistés Sociaux de la Rive Sud 7386 Union Régionale des Gardes Paroissiales de la Côte-Nord Inc._.7386 Union Régionale des Gardes Paroissiales de La Mauricie Inc.7386 llnion Régionale des Gardes Paroissiales de St-Hyacinthe Inc.7386 Union Régionale des Gardes Paroissiales des Bois Francs Inc.7386 Lettres patentes, Letter Patent, avis d'annulation notice of annulment (1\" avis) (1st notice) Durograf International Limited (Correction).7484 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires supplementary Allpak Industries Limited.7387 Arcand & A'rcand inc.7386 Boulanger (J.H.) limitée.7386 Bright Sleepwear Inc.7386 Caravane Plein-Air J.G.inc.7386 Champlain Loans Ltd.7387 Coats (J.& P.) (Canada) Limited.7386 Coats (J.& P.) (Canada) limitée.7386 Corporation de la revue Administration Hospitalière et Sociale inc.7386 Courtiers Sorentim inc.(Les).7386 Dionne (Albert) inc.7386 Distributions Cantines Mobiles inc.(Les).7386 Dominion Foam Corporation.7387 Entrepreneurs électriciens Le Voyageur inc.(Les).,.7387 Entreprises Laurent Girard ltée (Les).7387 Etrefal inc.7387 Gamache Exploration & Mining Co.Ltd.7429 Garde paroissiale de St-Félicien inc.7387 Gingras (Orner) & Fils inc.7387 Immeubles Fugère inc.7387 Industries Allpak limitée (Les).7387 Industries P.A.K.inc.7387 Le Voyageur, Electrical Contractors Inc.7387 Midterre Realty Ltd.7387 Nouveautés Linfin La Curasse inc.7387 P.A.K.Industries Inc.7387 Prêts Champlain ltée.7387 SolgustaCo.Ltd.7387 Valmos Corporation.7387 Sièges sociaux Head Offices Brasserie La Gargote inc.7442 Brisk Corporation.7447 Canexco inc.7446 Château Wong Restaurant Inc.7445 Cinéastes Associés Inc.(Les) .7442 Cinéma Shawinigan Inc.7449 Club de Hockev les Seigneurs de Boucherville inc.(Le).7446 Corporation Brisk.7447 Corporation Hockair (La).7447 Courtiers en immeubles Danière Inc.(Les).7443 Domaine Neveu inc.7442 Dupuis & Guertin inc.7447 Eiffel Construction Inc.7442 Entreprises Cubic ltée (Les).7448 Gestion Bougainville ltée.7445 Gould Auto Supply Co.7443 Granton Products Ltd.7446 Hockair Corporation.7447 Investissements M.L.R.S.ltée (Les).7444 Jobidon (G.) inc.7449 Kay, Martel inc.7445 Lemego Construction Ltd.7443 Maîsonneuve Automobiles Inc.7446 Medyrel Inc.7448 Mirabel automobile ltée.7444 Namron Realty Corp.7444 Oxygène Val-Mauricie ltée.7447 Place Norbert inc.7446 Placements Carisa Inc.(Les) .7445 Placements Grand Calumet inc.(Les).7443 Placements Monga inc.(Les).7444 Restaurant Château Wong Inc.7445 St.Michel Realties Inc.7444 St.Michel Realties (Montreal) Ltd.7445 Snap Industrial Construction Inc.7448 Transport R.Rochon Inc.7448 Val-Mauricie Oxygen Ltd.7447 Curatelle publique Public Curatorship Successions vacantes: Vacant estates: Lessard.Bertrand.7433 Ranger, Jean-Paul.7433 Rhéaume.Wilfrid.'434 7490 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15.1973, Vol.105, No.50 DEMANDES A APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Club de Golf Le Portage inc.7454 Hubert Lake Ungava Nickel Mines Limited.74 55 Saint Nicholas Russian Orthodox Church of Montreal (The).7454 Sherbrooke, cité-city.7450 LIQUIDATION DES WINDING-UP COMPAGNIES Loi de la .4CT Association coopérative des éditions socialistes (V).7449 Association coopérative forestière de Fabre.7449 Caisse Populaire Chute des Passes (La).7450 Placement « Baron » limitée.7450 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Bureau de revision de l'évaluation foncière du Québec ( Ville de I'Iessisvilte).7455 Québec Real Estate Assessment Board of Revision ( Town of Plessisville).7455 Institutions Financial financières, Institutions compagnies Companies et coopératives and Cooperatives Assurances: Insurance: Compagnie d'assurance mutuelle contre le feu de la paroisse de Saint-Herménégilde, comté de Stanstead (La) (Annul.).7461 Income Disability and Reinsurance Company of Canada (Name ch.).7460 Income du Canada.Compagnie d'Assurance-* Invalidité et de Réassurance (Nom ch.) .7460 Société anonyme française de réassurances (La) (Permis - Licence).7460 Transports Transport Entretien de routes discontinué.7455 Maintenance of roads discontinued.7455 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Certain Electoral districts Land Titles Act (R.S.Q.1964.Ch.321) its application to the cadastre of a part of the township of Cox.Electoral District of Bonaventure.7461 Certain Electoral districts Land Titles Act (R.S.Q.1964, Ch.321) its application to the cadastre of a part of the township of Percé, Electoral District of Gaspé (formerly Gaspé-South).\".7463 Coming into force of the official cadastre of a part of the township of Grenier, situated in the registration division of Saguenay.7405 Holiday and non juridical days.Decemlicr 20.1973 and January 2.1974,.7 167 Jours de fetes publiques et jours non juridique, le 26 décembre 1973 et 2 janvier 1974 7467 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie du canton de Grenier, située dans la division d'enregistrement de Saguenay.7465 Titres de propriété dans certains districts électoraux.Loi des (S.R.Q.1964.ch.321) son applications au cadastre d'une partie du canton de Cox.district électoral de Bonaventure .7461 Titres de propriété dans certains districts électoraux.Loi des.(S.R.Q.1964.ch.321) son application au cadastre d'une partie du canton de Percé district électoral de Gaspé (antérieurement Gaspé-Sud).7463 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: A.E.C.Corporation inc.7347 A.X.Electronics Corp.7347 Agence Musicale Internationale inc.7347 Agences Léo Gauthier inc.(Les).7347 Agences M.Guay inc.7347 Agences musicales Sagucnay-Lac-St-Jean ltée (Les)._.7347 Agences touristiques Cartier inc.7347 Ahuntsic Plumbing & Heating Co.Ltd.7347 Aide au foyer inc.(L').7347 Allmark Investment Ltd.7247 Aménagements Baie Plaisance inc.7347 Arche des jeunes (L').7347 Archers Laurentien (Les).7347 Adrien Construction Co.Ltd.7347 Arena de la Rive Sud incorporée.7347 Aresvillc Gardens Inc.7347 Argenteuil Equipment Limited.7347 Argus Press Corp.7347 Aril Holdings Inc.7347 Armoires de luxe inc.7347 Arncl Commercial Enterprises Ltd.7347 Arts Féminins île la Mauricie inc.(Les).7347 Arvida Tennis Club inc.7347 Association du Baseball de St-Hyacinthe inc.7347 Association de camping de Chandler inc.(L').7348 Association de chasse et pêche du serpent Notrc-Dame-du-Laus Que.7348 Association des cités des jeunes du Québec .7348 Association des Clubs de Service du Québec Métropolitain inc.(L').7348 Association des consommateurs avertis (L').7348 Association île danse A 1) R Q.7348 Association diccèsaine de:' commissions scolaires du diocèse de Trois-Rivières inc.(L').7348 Association des étudiants du CEGEP de Thet- ford inc.(L-).7348 Association générale des étudiants du collège de Jonquière.7348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7401 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations, (suite) (continued) Association des groupments en alimentation inc.7348 Association Jeunesse et Culture du Québec.7348 Association des loisirs du lac Rond inc.7348 Association nautique du lac Bleu inc.(L').7348 Association des numismates de Montréal inc.(L') .7348 Association parents-maîtres.St-Georges inc.8348 Association professionnelle des cinéastes.7348 Association des propriétaires des clialets des éboulis inc.(L').7348 Association des propriétaires du lac Bisbav (L').'.7348 Association des propriétaires du lac Matambin 7348 Association des propriétaires du lac Vert inc.(LO.\u2022.7348 Association régionale de natation amateur Rive Sud Métropolitaine.7348 Association sportive « Les Canadiens de l'Ile Bizard inc.».7348 Association Trois-Cap.7348 Assurances Pierre Alix inc.7348 Auberge des pins lac St-Joseph inc.7348 Auberges de jeunesse du Québec (l.es).7348 Aubin (Claude) ltée.7348 Auto C.O.V.Inc.7348 Auvicom Inc.7348 Avian Development Corporation.7348 Ayotte & Lambert inc.7348 B.G.L.inc.7348 B.H.Construction Inc.7349 B.L.M.Construction Inc.7349 B.L.R.Language Schools Ltd.7349 B.T.H.Construction ltée.7349 Baie du Nord fournies inc.(La).7349 Baillargeon (Yves) ltée.7349 Barkun Insurance Services Inc.7349 Barons de Rouvn-Noranda (Les).7349 Barrif Ltd.7349 Baycolnc.7349 Beaconsfield Club Shares Limited .7349 Beaudin (Charles A.) inc.7349 Beaulé Tuile et Tapis inc.7349 Bellemare (Roch) inc.7349 Berkshire Construction Corp.7349 Béton Minville inc.7349 Bibliothèque centrale de prêt du Saguenav- Lac-St-Jean.7349 Bidner (Samuel) inc.7349 Biencoltée .7349 Big Vallev Livestock Exporters Inc.7349 Bilral Inc.7349 Birmoss Park Limited .7349 Black and Cold Athletic Association Inc.(The) 7349 Black's (Lou) Living Room \" 67 \" Inc.7349 Blackstone Building Corporation.7349 Blanchard (F.W.) inc.7349 Blanchet (Gérard) inc.7349 Blé d'inde Paysan inc.(Le).Blevinal Boarding Home Inc.Blocs de ciment St-Jean inc.Blondin Leasing Inc.Bloomfield Agencies Limited.Bliimer Realties Inc.Boeuf sur le Toit inc.Bohème Haute Coiffure inc.(La).Bonaventure Holdings Limited.Bonneville Realty Inc.Boiilay (Jos) inc.Boutin (Gérard) ltée.Boutique Au Vieux Crcnier inc.Boutique Corinne de France ltée.Boutique Maxime inc.Boutique Taj-Mahal ltée.Boutiques Plateau Mont-Royal inc.Brault (Maurice) joaillier inc.CA.T.A.(L'âge d'or).C.L.P.S.Inc.Cadet Cleaners Limited.Café Tabouret ltée.(Le).Cantalia construction inc.Central l.and & Development Corporation .Centre d'achat Duberger inc.Centre astronomique de Montmagny inc.Centre civique de Joliette incorporée.Centre Colombien Sainte-Foy inc.(Le).Centre Jour inc.Centre loisirs danse Baie des Chaleurs.Centre du soulier italien inc.Cercle d'études en conduite automobile (C.E.C.A.).Chainpoux (Armand) inc.Chanson du Québec inc.(La).Chaussures le Gentilhomme ltée (Les).Chaussures Massy inc.Cidrerie de la vallée du Richelieu inc.Cincco Inc.Cinedome Theatres Ltd.Ciné-Parc Val loisii inc.Citadel Salvage Corporation.Citadel Steak House Inc.(The).Cité des jeunes de Hull.City Edible Refining Ltd.Club Au Rendez-Vous des Sportifs (Lac Caché) inc.;.Club automobile Bombardier.Club auto-neige Em-Bo de Rouyn-Noranda inc.; ¦ \u2022.Club auto-neige de Stc-Marie inc.Club d'aviation de Trois-Rivières inc.Club d'aviron de l'équipe du Québec inc.Club de baseball les Saints de Sainte-Thècle inc.(Le).Club Iti-Clou-Fil .Club de chasse & pêche Uchalne.Club de chasse et de pêche St-Gerraain-des-Monts.Club des 50 inc.Club Fontaine inc.7349 7349 7349 7349 7349 7349 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7351 7351 7351 7351 7153 7351 7351 7351 7351 7351 7351 7351 7351 7351 7351 7492 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, No.50 Aris de dissolution Notice of Eventual (centuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Club de hockey les Barons de Granby inc.735i Club du lac du Repos.7351 Club du lac Vermon inc.7351 Club de moto-neige les Etoiles des Pins inc.7351 Club optimiste I-orette.7351 Club parc Duchesncau.7351 Club de pêche du lac I.a .lustone inc.(I.e).7351 Club des Plaines inc.7351 Club l.e Raccourci inc.7351 Club des Raquetteurs (Tikouape) inc.7351 Club récréatif .loko inc.7351 Club Richelieu de Gatineau .7351 Club La Rose des Vents du Québec Métropolitain inc.7351 Club de ski de Gaspé inc.(Le).7351 Club sportif Blanc-Rouge-Vert inc.7351 Club sportif Pocomoco inc.7351 Club sportif de Victoriaville inc.(Le).7351 Club de tennis de Matane.7351 Club de tennis (St-Isidoie) inc.7351 Club Trois-Rivières Archers .7351 Club \\'icn inc.7352 Comeau (I.ouis) inc.7352 Comité des citoyens de Trois-Rivières.7352 Comité des loisirs des Trois Ruisseaux incorporée.7352 Compagnie de chaussures Pajar ltée.7352 Compagnie des matériaux de construction inc.(La).7352 Comptoir agricole St-Louis inc.7352 Concile des jeunes de Saint-Hyacinthe (Le) 7352 Conseil régional de bien-être de Sherbrooke 7352 Construction générale Sphex ltée.7352 Convene© of Canada Limited.7352 Corkoltée.7352 Cornucupia Investments Ltd.7352 Coronet Insurance Agencies Ltd.7352 Corporation immobilière B.& J.inc.7352 Crédits Val-Mont inc.(Les).7352 Cvclones de Warwick (Les).7352 Cyr (V.) Tire & Auto Service Ltd.7352 D.R.Rolling Metal Inc.7352 D'Avrav Properties Limited .7352 Decor Metal Ltd.7352 Delta Investments Inc.7352 Delta Techniques Ltd.7352 Derbv Pop Corn Inc.7352 Digucr (Bernard) 5-10-15 inc.7352 Discount Ista-Prints (D.I.P.) Inc.7352 Distribution Elite ltée____ .7352 Domaine de l'Avenir inc.7352 Domaine du Perchoir inc.(Le).7352 DowncaSter Development Inc.7352 Dromil Investment Inc.7352 Dromo Inc.7352 Dufault (Waite) Mines Limited.7352 Dufresne.Mclagan.Daignault inc.7352 Dunn Enterprises Incor|>oratcd .7352 Dwelling location Service Ltd.7353 E.T.Specialties Inc.7353 Ecole Thérèse Gauthier inc.7353 Ecolog-Motivation Inc.7353 Econar construction inc.7353 Edifice Trever inc./353 Elgar Mining Corp.Limited.7353 Em-Ar Development Corp.7353 Entreprises Arc inc.7353 Entreprises Armand Vadehoncocur ltée (Les) 7353 Entreprises BLB inc.(Les).7353 Entreprises Bocar inc.7353 Entreprises G & C inc.(Les).7353 Entreprises G.M.M.inc.(Les).7353 Entreprises H.O.M.ltée.7353 Entreprises Hospitalité limitée.7353 Entreprises J.I.S.inc.(Les).7353 Entreprises Jolades inc.(Les).7353 Entreprises L.P.B.inc.(Les).7353 Entreprises Labranche inc.(Les).7353 Entreprises Lafleur (1961) ltée (Les).7353 Entreprises Lallouz inc.(Les).7353 Entreprises Ltury inc.(Les).7353 Entreprises Maupier inc.(Les).7353 Entreprises Maurog inc.(Les).7353 Entreprises de meubles Luc Genest inc.(Les) 7353 Entreprises Mont Plaisant inc.(Les).7353 Entreprises Thomas inc.(Les).7353 Épicerie Savard & Fils limitée.7363 Équipement B.C.inc.7353 Euro-Studio limitée.7353 Fairwinds Corporation Ltd.7353 Favre & Fils limitée.7353 Fiederer (Ernest) Sales Inc.7353 Fondation artistique de Saint-.fean.7353 Fonds M a ska limitée.7353 Forcier (Edgar) & Fils inc.7354 4 Seasons Drive-in (Masson) Ltd.7354 Fournitures chirurgicales du Québec ltée 7354 Frontier Beagle Club.7354 G.A.Inc.7354 G.G.Graphics Inc.,354 G.M.Decal et Label liée.7354 G.P.Associates Inc.7354 G .T.Transport inc.7354 Gagné ((i.H.) Agencies Inc.7354 Gang du Barbillon inc.(La).7354 Garage A & B ltée.7354 Garthby Transport limitée.7354 Gatineau Petroleum Inc.7354 Gar.Ouellet (1962) liée.7354 Gélinas (Paul) inc.7354 Gélineau Auto Parts Inc.7354 i .¦n.-1 Developments Ltd.7354 Généreux construction inc.7354 Generic Pharmaceuticals Ltd.7354 Geneva Investment Limited.7354 Genoa Painting Inc.7354 Gerard Investments Inc.7354 Gero (Stephen) Realties Inc.7354 Gertoltée.7354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7493 j Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Gestnan limitée.7354 Giguère & frères inc.7354 Golden Arms Club Inc.(The).7354 Gordonia Ltd.7354 Granby Holding Ltd.7354 Granby Spinning Mills Ltd.7354 Grand Construction Ltd.7354 Grand Pavillon (Hull) inc.7354 Grand Temple Pvtbian Sister (P.S.) of Québec Inc.7354 (irande Vue Construction Co.Ltd.7354 Grange 32 inc.7354 Greek Progressive Association of Canada inc.7355 Greek Radio Wire Programs Inc.7355 Greenpark Construction Co.Ltd.7355 Grondin (.lean) inc.7355 Grondin (Stanislas) inc.7355 (iuay (Jacques G.) et Associés inc.7355 Guide de sécurité inc.(Le).7355 Guimel inc.7355 Hadjizade Land inc.7355 Hamel (Lucien) Construction Inc.7355 Haruni Metal Products Ltd.7355 Harvey (Bert) Corporation.7355 Hellenic Food Industries Co.Ltd.7355 Henri-Ette Dress Inc.7355 Hickory Industries International Sales Corporation .7355 Hilltop Nursery and Greenhouses Ltd.7355 Home Laundry Materials of Canada Inc.7355 Hôtel George (Rouvn) limitée.7355 Hôtel Paquet ltée.7355 Hôtel Rocher Blanc ltée.7355 Hôtel St-Louis (l,a Sarre) inc.7355 Hôtel Taillefer et Fils inc.7355 Huiles Laflamme inc.(Les).7355 I & C Construction Inc.Z - Immeubles (îaudet inc.(Les).7355 Immeubles Impérial Cie ltée.7366 Immeubles Labrosse inc.(Les).Immeubles Ladoumond inc.(Les).'355 Immeubles Pierre Nan tel inc.7355 Immeubles Outremont Realties Inc.7355 Immeubles et Prêts J.P.L.inc.7355 Importation Voici inc.7355 Industrial Teletypewriter Electronics Corp.7355 Industries Grondin & Doucet inc.7355 International Ciné-Club inc.7355 International Premier Pizza King Corporation 7355 Inventions Catien & Major ltée (Les).7356 J & J Promotion Inc.7356 J & M Leather Goods Ltd.7356 J.M.I.Holdings Inc.7356 J.P.B.Automate Inc.7356 Jackson Hardware Mfg.Ltd.7356 Jacques (J.L.) transport inc.7356 Jarry Restaurant inc.7356 Jeniont Inc.7356 Jetronics Corporation.7356 Jcunac Inc.7356 Jeune Chambre de Mont Laurier (La).7356 Jeune Commerce de Lyster.7356 Jeune Commerce de Québec-Ouest inc.(Le) .7356 Joa Management Ltd.7356 Jobson (Ray) Inc.7356 Joda Investment Corp.7356 Johnstall Entreprises Inc.7356 Jolil Company Ltd.7356 Jolin Construction ltée.7356 Joro Investments Ltd.7356 Joseph Le Tailleur inc.7356 Jourdain & Lorrain inc.7356 Journal La Vie (1969) ltée (Le).7356 Junior B de Thetford inc.7356 Junior Holdings Inc.7356 K & M Meat Market Inc.7356 Kalo Realties Ltd.7356 Kam Sam Corporation.7356 Kanash Investment Corporation.7356 Kanawid Inc.7356 Kaprisse inc.7356 Karen Realties Inc.7356 Katz (M.) inc.7356 Kel Taxis Ltd.7357 Kelven Co.Ltd.7357 Kempson Inc.7357 Kernor Corporation.7357 Kessler Industries Inc.7357 Kimpton Dupuit Agancies Limited.7357 King Kong Café de Thetford inc.7357 Kiron Investment Corporation Ltd.7357 L.B.Service Inc.7357 L & M Transport Inc.7357 L.M.S.Construction Inc.7357 L.T.L.Inc.7357 Labbé autos (1964) inc.ergc de Jeunesse Vive La Vie.7367 Autos Bretagne inc.7367 Base plein air Saguenay inc.7367 Buskutong Mining Corporation.7367 Bejado inc.7367 Bell Provisions Inc.7367 Bcrdov (J.) & Cie Inc.7367 Bcs Construction Inc.7367 Biscuiterie Jacquot inc.(Us).7367 Boutique Roméo et Juliette inc.7368 Bureau (Lorenzo) inc.7368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 décembre 1973, 105' année, n° 50 7497 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Camionneurs indépendants de Lotbinière inc.(Les).7368 Camping lac McGregor inc.7368 Canadian Association of Young Men of Istam- bul.7368 Can-Ital Investments Ltd.7368 Centrale de logements J.M.J, inc.7368 Centre de décoration La Tuque inc.7368 Centre d'études politiques de Québec et de la région inc.7368 Centre de jeu de paume du Québec inc.7368 Centre récréatif du lac Lyster inc.7368 Clermont (Jean R.) inc.7368 Club des Anges inc.(Le).7368 Club d'auto-neige Val Morin inc.7368 Club de chasse et pêche du lac East Branch Pond inc.7368 Club de chasse et de pèche Magpie inc.7368 Club copains-copains Métropolitains.7368 Club de Croquet Québec inc.7368 Club Hermine inc.7368 Club de hockey Pee Wee international de Ste-Foy.7368 Club du lac Rudolphe inc.7368 Club de moto neige les Aigles de Ste-Anne-des- Montsinc.7368 Club de la rivière Corneille inc.7368 Club des sentiers (Nord de Juliette) inc.7368 Club social Mercure inc.7368 Club sportif Compton inc.7368 Comité des loisirs Saint-Nom-de-Jésus ltée.7368 Comité Québécois d'aide et de développement (Tiers-Monde).7368 Commercial Consumers' Marketing Corp.7368 Commission des loisirs de la municipalité de St-Calixte inc.7368 Compagnie de construction Sodec (La).7368 Compagnie d'équipement et réfrigération Frontenac inc.7368 Compagnie franco-canadienne d'alimentation incorporée (La).7368 Compagnie Kirby de Montréal inc.(La).7368 Compagnie de publication du journal l'Echo du Dimanche inc.(La).7369 Concrete Repairs & Waterproofing Co.Ltd.7369 Conseil de l'âge d'or du secteur Lapointe.7369 Conseil d'habitation économique Beauport ltée.7369 Conseil St-Henri (Le).7369 Considines Sales Limited.7369 Consolidated Industrial Ventures Ltd.7369 Consolidated Maple Products Ltd.7369 Consolidated Mortgage Swiss International of Quebec Inc.7369 Constro Design Inc.7369 Constructions Jocelin ltée.7369 Consumers Discount Club Inc.7369 Contempora Inc.7369 Continental Minerals and Resources Ltd.7369 Contreplaqués Trois Plis inc.7369 Cookshire Metal Works Ltd.7369 Copia Investment Corp.7369 Coppernic Mines Ltd.7369 Cordina Inc.7369 Coronet Voyages inc.7369 Corporation de développement jeunesse.7369 Corporation Dicom.7369 Cosy Housing Inc.7369 Côté (J.Léonard) & Fils inc.7369 Côté, Lizotte, Emond inc.7369 Côté (Marcel) musique inc.7369 Côte-Noire Development Inc.7369 Côte-Nord Para Club Inc.7369 Coulonge Lumber Co.Ltd.7369 Crequette Enterprises inc.7369 D.G.S.Inc.7369 D.L.F.Investments Ltd.7369 Danube Trading (Québec) Ltd.7369 Darrick Mines Ltd.7369 David (P.) Construction Inc.7369 Del-Fran Service inc.7369 Delisle (J.P.E.) inc.7370 Desjardins (Roger) inc.7370 Desmarteau (Charles), courtier en immeuble inc.7370 Dialogue (du Québec) inc.(Le).7370 Didacta inc.7370 Diffusions internationales du livre inc.7370 Dimac inc.7370 Dimension Sherbrooke.7370 Dimensions Uya Incorporated.7370 Dimpex Corporation.7370 Dolemer inc.7370 Dubois (J.I.) limitée.7370 Duver Creek Gold Mines Limited.7370 Dwayne Fashions Inc.7370 Easy-Tow Trailers Company.7370 Ecole des langues de Montréal inc.7370 Ecuries St-Joyite inc.(Les).7370 Edition diffusion Iscrman inc.7370 Elba inc.7370 Entreprises Assiniwi ltée (Les).7370 Entreprises Dauville inc.(Les).737C Entreprises G.& F.Desmarais et frère limitée (Les).7370 Entreprises du grenier limitée (Les).7370 Entreprises interurbaines inc.(Les).7370 Entreprises Jad inc.(Les).7370 Entreprises Jalmark inc.(Les).7370 Entreprises Jalmark inc.(Les).7370 Entreprises Lagate inc.(Les).7370 Entreprises Lucien Tremblay inc.(Les).7370 Entreprises Meico inc.7370 Erb-Cor Ltd.7370 Eurocan Developments Ltd.7370 F.T.Food Consultant Inc.7370 Fashion Converters Ltd.7370 Fashionknit Imports (Québec) Ltd.7370 Favourite General Contractors Co.Ltd.7370 7498 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 15, 1973, Vol.105, Xo.50 Lellre.i patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Federation île la jeunesse sportive d'lberville inc.-¦\u2022 7370 Fédération de judo et des arts martiaux inc.(La).7370 Fédération de karaté du Quél>ee (La).7371 Fédération nationale des aulicrges de jeunesse du Québec inc.7371 Fédération provinciale des commerçants détaillants (La).7371 Fédération québécoise de karaté inc.7371 Fédération de ski du Québec.7371 Ferme maraîchère Côte-Nord inc.(La).7371 Ferme récréative St-Modestc inc.(La).7371 Ferme de St-Jean-de-Matha inc.7371 Formdec limitée.7371 Foyer de l'Ile d'Orléans inc.7371 Franklin Quarries Inc.7371 G.D.Sales Co.Ltd.7371 G.J.M.D.ltée.7371 Galerie Martin inc.7371 Galeries de l'Aigle inc.7371 Gerard Steel Products Ltd.7371 Gestion Provence Inc.7371 Gi Cor Inc.7371 Gtte ouvrier inc.(Le).7371 Golden Phoenix Restaurant Ltd.(The).7371 Golfax Inc.7371 Habetinc.7371 Habitations Lachenaie ltée (Les).7371 Hamel et I.ahaye construction inc.7371 Holiday Magic Distributors Association of Montreal.7371 Hôpital Maisonneuve.7371 Hôtel Motel St-Jean inc.7371 Immag Corp.Ltd.7371 Immeubles Coulombe ltée (Les).7371 Immeubles G.J.D.inc.(Les).7371 Immeubles Lamont inc.(Les).7371 Immeubles Ray-Jean inc.7371 Immeubles du vieux quartier inc.(Les).7371 Imprimerie Lanaudière inc.7371 Imprimerie Maurice Simard inc.7371 Im-Val inc.7371 Inbec inc.7372 Indépendant Veterans Association.7372 Industrial Motor & Transmission Specialties Inc.7372 Infor-Vison Québec liée.7372 7372 7372 Inserva (Canada) ltée Installations électriques du Québec inc.(Les) Institut d'enseignement par correspondance du Quél>ec inc.(L').7372 Institut de programmation J.L.L.inc.7372 Interchange Hospitality Club Inc.(The).7372 Intercoastal Properties Ltd.7372 Inter-Service Clubs Council.7372 Intrevic Inc.7372 Iprcp Inc.7372 Irish House Corporation.ï3!^ Iter Servide Inc.7372 J.L.Marine Equipement inc.7372 J.M.Transport ltée.7372 J.P.Auto ltée.7372 J.P.Construction Inc.7372 J & R Holdings Co.Ltd.7372 J.T.Isolation Inc.7372 J.& W.Investments Inc.7372 Jabin inc.7372 Jacken Inc.7372 Jacques automobiles inc.Jacques Marc Development Inc.7372 James Sterling Paper Fashions (Canada) Ltd.7372 Janin-Trudcau compagnie ltée.7372 Jasna construction inc.1^1?Jean Pierre auto inc.737.¦Ici Corp.7372 Jcrno rénovation inc.i _ Jenkins Tétrault construction inc.7372 Jéricho Trading Co.Ltd.7372 Jetic inc.7372 Jeuneq inc.7372 Joanne modes inc.7372 JoIk» Investment Corporation.7373 Joëlle ltée.7373 Jolema Publishing Ltd.7373 Jolvmont inc.(Le).7373 Jones Building Ltd.7373 Joseph (M.) & Co.7373 Jouets provinciaux inc.7373 Journal de St-Léonard (Le).7373 Journal de Sherbrooke inc.(Le).7373 Journaux unis du Québec inc.(Les).7373 Joyelle inc.7373 Joyeux promeneurs inc.(Les).7373 Jules rénovation inc.7373 Julian Investment Corporation.7373 Juno Investments Incorporated.7373 .lustras (G.) inc.7373 Jutras & Jutras inc.7373 Kamico ltée.7373 Kangaroo Speed Shop Inc.7373 Kargo Express ltée.7373 Kaxle Realties Inc.7373 Kent Trading Inc.7373 King (Wayne P.) & Ass.Inc.7373 Koban Cosmetics Ltd.7373 l.abcrge (Normand) inc.7373 Laboratoire médical Métropolitain.7373 Laboratoires Cosmel'l inc.7373 l.abranche & fils inc.7373 Laiterie Saguenay-Lac-St-Jean (La).7373 laiteries Pee-Wee inc.(Us).7373 Lake Copper Ltd.7373 Lam Tronique ltée.7373 La-Mai vallée inc.7373 Lamarre construction inc.7373 Lamigo inc.7373 Lamothe automobile (1964) ltée.7373 Lnnar inc.7373 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 décembre 1973, 105' aimée.n° 50 7499 Lettre* patentes annulées: fetters Patent Annulled: (suite) (continued) I.anglais (X Raymond) Holding Inc.7374 Lanorac inc.7374 Laurenlian Sales Co.Ltd.7374 Lefebvre (Jacques) inc.7374 Lessard (G & R) inc.7374 Lessard (J.L.) construction ltée.7374 Librairie Héroux ltée.7374 Ligue des contribuables de Lacbute.7374 Litwack (Lyonel) Converters Inc.7374 Lloyd (J.R.) Montreal.7374 M.G.M.inc.7374 M.I.Interior Maintenance Inc.7374 Machinerie lourde André Doré inc.7374 Mackie (Iain D.) & Co.Ltd.7374 Mag-Mont Ltd.7374 Marks & Martin inc.7374 Marois et Séguin inc.7374 Martin Steel (1966) Ltd.7374 Mary Ann Services Ltd.7374 Mc Donald Héron corporation.7374 Meco Electric (1960) inc.7374 Meco Electric (Que.) inc.7374 Mesotek inc.7374 Métallurgie de l'Islet ltée (La).7374 Metro Offset Inc.7374 Meubles Diana inc.7374 Mexicana Mining Corporation.7374 Miracle Painting and Contracting Inc.7374 Mom.Restaurant Ltd.7374 Mo-Mer électrique inc.7374 Mont Alpino inc.7374 Montcalm Mines Ltd.7374 Mont-Mill inc.7374 Montreal Alumni Club of Tau Kappa Epsilon Fraternity Inc.(The).7374 Montreal Jet Port Investment Ltd.7374 Montreal Settlement In Israel Inc.7374 Monument Construction Co.Ltd.7374 Motel Le Savoie inc.7375 Xacren Industries Ltd.7375 Narp Limited.7375 Xational Diesel Ltd.7375 Xebraska Meat Company Ltd.7375 Xettoyeur Montcalm inc.(Le).7375 Xirab Industries Limited.7375 Xoik Bros Construction Co.Ltd.73/5 Xortherly Industrial Corporation.7375 Northland Optical Services Inc.7375 O'Brien Motors Ltd.7375 O-Cornet inc.7375 Oeuvre des loisirs St-Joseph-des-Patios (L').7375 Oeuvre des loisirs de St-Thomas-Didyine inc.(L').7375 Oeuvre des loisirs de Ste-Croix inc.(L').7375 P.L.Equipement ltée.7375 Park Lane Furniture Inc.7375 Patino Mining Corporation (The).7375 Peintures Bel-Tone (Québec) inc.7375 Pelletier & associés inc.7375 Pharmacies Mont Rose inc.(Les).7375 Pièces d'automobiles Marseilles inc.(Les).7375 Pigeon Service Station Inc.7375 Placements Probec inc.7375 Placements Saint-Martin inc.(Les).7375 Placements Sept-Iles ltée (Les).7375 Placement V.T.V.inc.7375 Plomberie et chauffage G.V.inc.7375 Polgro Investment Inc.7375 Pomerleau (Roger) automobiles ltée.7375 Pontiac Social Planning Council Inc.(The).7375 Poulet Pop inc.7375 Precision Machining & Welding Inc.7375 Prévost (J.G.) assurances inc.7375 Procbar Corp.7375 Production P.M.D.inc.7375 Produits Cardinal inc.(Les).7375 Promotions Saguenay-Lac St-Jean inc.(Les).7376 Publications Hebdo-Québec inc.(Les).7376 Quartet Properties Inc.7376 Québec Construction Subcontractors Association.7376 Québec Contract Documents Inc.7376 Québec Scientific Instruments Inc.7376 Quilles Pie IX (1966) inc.7376 Raidie (J.M.) inc.7376 Raycoms Radio Inc.7376 Recousse (La).7376 Redmond & Bros (Birch Dimension) Ltd.7376 Relex International Inc.7376 Renovatec Inc.7376 Republic Funding (Québec) Limited.7376 Résidence Jean-de-la-Lande inc.7376 Restaurant Côte du lac ltée.7376 Restaurant La Madelon inc.7376 Restaurant Monaco (1967) inc.7376 Resthaven Convalescent Home Ltd.7376 Rive Nord auto inc.7366 Ronald fruits et légumes ltée.7376 Ruffo (Jean) ltée.7376 St.Constant Industrial Park Inc.7376 St.Jérôme Steel Mfg.Co.Ltd.7376 Salon du Golf inc.7376 Sansoucy (Jean) ltée.7376 Sauvé (J.P.Robert) et associés incorporée.7376 Sauvé Transport Inc.7376 Seaway Nursery & Landscape Ltd.7376 Serres Iberville inc.7376 Servi Consultants Inc.7376 Service Castel Laval inc.7376 Service central de construction Jul ien i ne.7376 Service des loisirs St-Jacques de Montréal.7377 Service des loisirs St-Justin.7377 Shaffan Distributors Ltd.7377 Sherwin Converters Inc.7377 Sicula Association of Montreal.7377 Société de gestion Montbro inc.7377 Société Jolumi inc.7377 Socimco inc.7377 South Shore Roofing & General Contracting Ltd.7377 7Ô00 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 16, 197S, Vol.105, No.50 lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Steel Mart Corporation.\"377 Sun Ware (Rive-Sud) limitée.7377 Technical Consulting Service Ltd.7377 Timbres Unico inc.7377 Toni Dress Shop & Furs Inc.7377 Transglobal Imports Inc.7377 Union générale des étudiants du Québec (U.G.E.Q.).7377 V.I.P.Club of Montreal Inc.(The).7377 Vo-Pray Inc.7377 West Island Equipment Ltd.7377 Wright Machine.Tool & Die Ltd.7377 Revocation de dissolution: Revocation of dissolutions: Associated Projects Inc.7377 Aubin & St-Pierre (Drummond) inc.7377 Beaver Mining Corporation.7378 Ben transport limitée.7378 Canadian Trans-Video Incorporated.7377 Club An-gi-lou inc.7377 Club Chasse-Galerie.7378 Club Connor.7378 Club de la Yérendrye.7378 Club des Trois Passes inc.7378 Club du Faisan de Drummondvillc 7378 ClubMikilnc.7378 Club Ncmrod Inc.7377 ChibTino.7378 Entreprises Pa.quet inc.(Us).7378 Entreprises Parc Lafontaine inc.7378 Immeubles Authier ltée (Les).7378 .I.B.Films inc.7378 Marché central (Québec) inc.7377 Québec Transportation Brokers Inc.7378 Restaurants Orléans inc.7378 SOUMISSIONS demande de Lalonde.e.s.r.-r.s.h.TENDERS \u2014 Request for .7458 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Association des chiropraticiens du Québec Inc.(Nom-Naine ch.).7458 Association des chirurgiens généraux de la Province de Quél>ec (Nom ch.).7457 Association of General Surgeons of the Province of Québec (Name ch.).7457 VENTES SALES Par Shérifs By Sheriffs Bonaventure Bonaventure Caisse populaire de St-Omer (La) M Arse- nault.7468 Grenier vs Langlois.7468 Hauterive llauterive Ragueneau, munie, vs Desrosiers 7469 Montréal Montreal Caisse Populaire de St-Jean rs Martin (Cor- rection).7484 Caisse populaire de St-Marc de Rosemont r* Coulombe et al .7471 Caron rs Pelissicr.7470 Caron rs Pclissier.7472 Caron vs Pelissier.7473 Citv of Laval (The) vs Le rose et al.7473 Gukv M Smith Cubell.7472 Mount Royal Tile and Tcrrazzo Inc.vs Os- min Construction inc.7469 Ville de Laval (La) vs l.aroseeta/.7473 Terrebonne Terrebonne Canada Florring Ltd.rs Masse.7474 Centre d'Aluminium vs Bélanger.7474 Taxes Taxes Beaconsfield, cité-city.7475 Chateauguay, ville-town.7479 Mercier, vilie-lown.7476 Princeville, ville-town.7475 SOMMAIRE Avis DIVERS.7428 Caisses d'épargne et de credit.7426 Changement de nom.Loi du: Demandes.7430 Commission des transports du Québec.7389 Compagnies, Loi des: Abandon de charte.7387 Changement de nom.* 388 Demandes d'abandon de charte.7434 Divers.7440 lettres patentes (1\" partie).7379-7484 lettres patentes (3' partie) 7385-7429 Lettres patentes (avis d'annulation) (1\") 7484 Lettres patentes supplémentaires.7386-7429 Siège sociaux.7442 Compagnies étrangères.Loi des: Agent.7433 Curatelle publique.7433 Demandes à la Législature 7450 Liquidation, Loi delà:.7449 Ministères: Affaires municipales.7455 Institutions financières, compagnies et coopératives: Assurances.7460 Transports.7455 Proclamations.7461 Renseignements sur les compagnies: Avis de dissolution éventuelle de corporations 7347 Lettres patentes annulées.7366 Révocation de dissolution.7378 Soumissions.7458 Syndicats professionnels, Ix»i dm.7457 Ventes: Par Shérifs: Bonaventure.7468 Hauterive.7469 Montréal.7469-7484 Terrebonne.7474 For taxes .7475 Sl'MMARY Applications to Lesislature.7450 Change of Name Act: Applications.7430 Companies Act: Applications for surrender of charter.7434 Change of name .7388 Head offices.7442 Letters patent (Notice of annulment (1st) .7484 Letters patent (Part I).7379-7484 Utters patent (Part HT).7385-7429 Letters patent supplementary.7386-7429 Miscellaneous .7440 Surrender of charter .7387 Companies Information Act: Letters Patent Annulled.7366 Notice of Eventual Dissolution of corporations 7347 Revocation of Dissolution.7378 Departments: Financial Institutions, Companies and Cooperatives: Insurance.7460 Municipal Affairs.7455 Transport .7455 Extra-Provincial Companies Act: Agents.7433 Miscellaneous Notices.7428 Proclamations.7461 Professional Syndicates Act.7457 Public Curatorship.7433 Québec TRANSPORT Commission., .,.7389 Sales: By Sheriffs: Bonaventure.7468 Hauterive.7469 Montreal .7469-7484 Terrebonne.7474 For taxes.7475 Savings and Credit Unions.7426 Tenders.7458 Winding-Up AJAN^' v * Édifice « G > Québec, Canada G1A1G7 S» "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.