Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 22 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1973-12-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE QUEBEC 2»T\" OFFICIELLE OFFICIAL -DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7509 PARTIE 1 ftwfcfc VVIS AUX ANNONCEURS W2>/ .1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel P\\a>1 du Québec, Québec, toute communication d'avis desti-Ç\"C.Z.n^e à 'a Gazelle officielle du Québec.r- 2.La Gazelle officielle du Québec est composée de |£ deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contient desavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, ù cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Editeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazelle, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Quebec Official Gazelle is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazelle.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements arc payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.0.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazelle (part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to ilefer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHAULES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 7510 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December SU, 197S, Vol.105, No.51 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture, le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dlbé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part I): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazelle carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Quebec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande renseignements concernant For information concerning the publication of publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la notices, off-prints or subscription rates to the Québec Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Official Gazette, please call: Georges Lapicrre Gazelle officielle du Québec-Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité' Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.Georges Lapierrc Québec Officiai Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973.105- aimée, n° 51 7511 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4.5a and following of the Companies Information Act.the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act.for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie .Vamf of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.M.ELECTRICAL SUPPLY CO.LIMITED.ADDINGTON REALTY CORP.AGENCE D'ASSURANCE INTEU-CITE INC.AGENCE DE PUBLICITE MERCANTILE INC.AGENCE DE VOYAGE COLUMBUS (1972) LTEE.LES AGENCES L.A.R.INC.AIR MONTREAL INC.ALAMEDA HOLDINGS INC.THE ALEX FISH & GAME CLUB.ALLIED HANDLING & STORAGE EQUIPMENT LTD.ALOUETTE AVIATION INC.ALPENHOF CLUB COTTAGES LIMITED.ALPHA CONSULTANTS & PROJECT OVERLOAD INC.ALPRO INC.JAMES ALTON'S INDUSTRIES LIMITED.ALVICAL CO.LTD.AL-VINYL MFG CO.LTD.ALYCE COSMETICS CORPORATION.AMALGAMATED MINING DEVELOPMENT CORPORATION LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) AMEDO INC.AMERICAN COl'KEESHOP INC.AMERICAN MINES AND MINERALS LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) LES AMIS DE llOSEMONT INC.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1972, 1973 Montréal.1963 à/to 1965 incl.1972, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.196S à/to 1973 incl.St-Romuald-d'Etchemin.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Alma.1972, 1973 Dorval.1968 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1964 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1964 à,'to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Grand-Mère.1965, 1969 à/to 1973 incl.Roaemont.1963.1904, 1907 à/to 1973 incl. 7512 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Nam» of the company LES AMITIES CULTURELLES CANADA FRANÇAIS ISRAEL INC.AMMAR ESTABLISHMENT LTD.DAVE AMSEL INC.LES AMUSEMENTS JACQUES FILIATRAULT INC.ANDIA LIMITEE.ANDOVER CONSTRUCTION INC.ARISTO-CRAFT NECKWEAR OF QUEBEC INC.ARLEQUIN AUX-DEUX-MASQUES INC.ANDRE ARSENAULT INC.ASSOCIATION DES COMMISSAIRES INDUSTRIELS DU QUE-BEC L'ASSOCIATION DIOCESAINE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU DIOCESE DE PEMBROKE (PARTIE DU QUE-BEC) INC.ASSOCIATION DES GRAVEURS DU QUEBEC INC.ASSOCIATION DES INSTALLATEURS EN ALUMINIUM DU QUEBEC L'ASSOCIATION ITALO-CANADIENNE DE L'OUEST INC.L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE THURSO INC.ASSOCIATION DES OFFICIERS DE PROBATION DU QUEBEC INC.ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC LOUISE.L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE ST-CONSTANT INCORPOREE ASSOCIATION SPORTIVE DES POLICIERS ET POMPIERS DU QUEBEC INC.ATELIER LES ARTISANS DU FEU INC.ATELIER JEAN M.COUTURE INC.LES ATELIERS GODART INC.ATLANTIQUE EXPRESS INC.AU LAVOIR INC.AU PECHE MIGNON INC.AUBERGE HILLCREST INC.AUBERGE DE LA VIEILLE FRANCE INC.AUTO PARC BONSECOURS INC.AUTO-NEIGE ESKIMO INC.B & D ELECTRONICS LTD.BACCHUS RESTAURANT INC.W.J.BARBER & CO.LTD.BAVER INTERNATIONAL INVESTMENT & SECURITIES CO.LTD.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1973 CôteSt-Luc.1972 et/and 1973 Ste-Thércse.1964.1966, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Mont-Royal.1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1958, 1969 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Fort Coulonge.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montréal.1972, 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Thurso.1972, 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Adolphe-d'Howard.1964 à/to 1973 incl.St-Constant.1965, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Chicoutimi.1969 à/to 1973 incl.Québec.1972, 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Pont Viau.1965 à/to 1973 incl.SherbrooUe.1946 à/to 1973 incl.Ste-Jovite.1967, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Dorothée.1967 à/to 1973 incl.Ste-Hénédine.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SS décembre 1973, 105- année, n° 51 7513 Nom de la compagnie Name of the company BEAVERTON REALTY CORPORATION.BENNY & FRERES LTEE.JACQUES BERGERON INC.BERKSHIRE SPORTSWEAR LIMITED.BERLY CONSTRUCTION INC.BERMAR CONSTRUCTION CO.LTD.BERTCO CREDIT INC.BERTOL INDUSTRIES LTD.BERTRAND & FRERE LTEE.BETA ALPHA HOUSE CORPORATION OF DELTA GAMMA.BETH REALTIES (CHAMBLY) INC.BIJOUTERIE STE-GEKTRUDE INC.LES BIJOUTERIES MICHAUD INC.BIO SOL INC.A.BISAILLON LIMITEE.J.P.BOISVERT INC.BOIVIN & BOIVI.N INC.RAYMOND BOLDUC INC.BOTTIN D'AFFAIRE ASSURANCES DU QUEBEC INC.LA BOUTIQUE DU FUMEUR LIMITEE.BOUTIQUE MLLE DENISE INC.BOWAR CONSTRUCTION INC.BROWNSBURG SOCIAL AND ATHLETIC CLUB.BUILDING CONSULTANTS CORPORATION.BUREAU DE CREDIT DE L'ESTRIE INC.C.G.CONSTRUCTION LIMITEE.C.M.R.ELECTRIQUE LIMITEE.C.M.T.HOLDINGS CORP.C.O.P.PLUMBING & HEATING CO.LTD.CAMP VALECO INC.CAN AM CONSULTANTS AND ASSOCIATES LTD.CAN CONSTRUCTION COMPANY.CAPITOL JEWELLERS INC.CARILLON ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE.LE CASSE CROUTE DU JARDIN DES ETOILES INC.CENTRE D'EDUCATION TECHNIQUE DU QUEBEC INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Félix-de- Valois.1973 Montréal.1964, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.La Salle.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Micliel.1969 à/to 1973 incl.Montréal .1972 et/and 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal .1963, 1964, 1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 incl.Montréal.1965, 1968 à/to 1973 incl.Tiois-Riviires.1972 et/and 1973 Châteauguay-Village.1956, 1970 à/to 1973 incl.Noranda.1904 à/to 1973 incl.Pont-Vian.1969 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1966 à/to 1973 iml.Montréal.1967 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1970 à.to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 et/and 1969.1973 Brownsburg.1973 Montreal.1967 à to 1973 incl.Sherbrooke.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Laval.1966, 1967.1970 à,to 1973 incl.St-Michel.1963 à/to 1973 iml.Ile Perrot.1969, 1971 à,to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Montreal.1972 et/and 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1969.1972 et/and 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1909 à.to 1973 incl.Montréal .1967, 1971 à.to 1973 incl. 7514 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed CENTRE OCTAVE CREMAZIE INC.CENTURY MINING CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY} CERCLE CULTUREL DE LA COTE DE BEAUPRE.CERCLE SPORTIF « CONSOL » DE ROBERVAL INC.CHALET ALOUETTE INC.LES CHARCUTERIES TETE DE LARD LTEE.CHAUFFAGE URBAIN INC.CHERR1ER HOLDING CO.LTD.LES CHEVALIERS DE ST-MAURICE INC.CHEZ ERCOLE INC.CHEZ ROSALEEN (ONTARIO ST.) INC.CHICKEN BURGER RESTAURANT INC.LA CIE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION RAVIN LTEE CIE NATIONALE D'ASPIRATEURS LTEE.CINE PARC DES ILES INC.530 SHERBROOKE EST LIMITEE.CLINIQUE ESTHETICARE INC.LE CLUB ALTBU8A DE QUEBEC.CLUB AU 230.CLUB BEAUDIN INC.CLUB LE BON SPORTIF (LAVAL MONTMORENCY) INC.LE CLUB DES CHEVALIERS ST-GEDEON INC.CLUB CYCLISTE D'ALMA INC.CLUB DE GAMBOA.CLUB HARO.CLUB DU MONT-ORFORD INC.CLUB DE NATATION DU SAGUENAY INC.CLUB OPTIMISTE DE GATINEAI\".CLUB OPTIMISTE DE POINTE-GATINEAU.LE CLUB OPTIMISTE DE SOREL TRACY INC.CLUB OPTIMISTE VANIER INC.CLUB DE PECHE AU SAUMON TRINITE.CLUB PICHOU INC.CLUB SOCIAL MONK .Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Ste-Anne-de-Beaupré.1971 à/to 1973 incl.Roberval.1964 à/to 1973 incl.Foster.1968, 1970, 1972, 1973 Longueuil.1971 à/to 1973 incl.Hull.1966.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1960, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Charle»bour«.1972 et/and 1973 Laval.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1970 et/und 1973 Montréal.1971 à,to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1969 à to 1973 incl.La Sarre.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1961 à/to 1970 incl., et/and 1972 Ste-Brigitte-de-Laval.1965 à/to 1973 incl.St-Géd«on.1972 et/and 1973 Aima.1966 6/to 1973 incl.Montréal.1973 La Malbaie.1954 à/to 1973 incl.Mont-Orford.1965 à/to 1909 incl.1971 à/to 1973 incl.Chieoutiml.1963 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Gatineau.1972 et/and 1973 Pointe-Gatiueau.1970 à/to 1973 incl.Tracy.1967 à/to 1973 incl.Vanier.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/anil 1973 Aima.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1073 incl. GAZETTE OFFICIEL^ QUÉBEC, 32 décembre 1973, 105' année, n° 51 7515 Nom de la compagnie Name of the company LE CLUB SOCIAL DE LA PLACE DE PASPEBIAC.CLVB SPORTIF LA GRANGE ALBERT.CLUB SUBSIDE.CLUB TERMINUS.CLUB DES 21 INC.COATICOOK COUTURE INC.COATICOOK DRV CLEANING INC.COFABRA INC.COFINCO INCORPOREE.J.COGAN INC.COHEN GERSHO REALTIES LTD.COIN EXCHANGE LTD.COLISEUM REALTY CORP.COLM INVESTMENTS LTD.COLONIAL ELECTRONICS LTD.COLONIE DE VACANCES DU SACRE-COEUR.COLOSSEUM BUILDING MAINTENANCE SERVICE CO.LTD COLOUR GRAPHICS CORP.COLUMBIA PLASTICS CORP.COM MON INVESTMENTS INC.COMEXFOR LTD.COMITE DE LOISIRS DANSE DE PAPINEAU.COMMISSION DES LOISIRS DE GATINEAU INC.LA COMMISSION DES LOISIRS DE POINTE-GATINEAU INC.COMMODORE INC.COMMODORE REALTIES INC.COMMONWEALTH AUTOMOBILE SALES & SERVICE INC.COMMUNICATIONS ELECTRO (QUEBEC) LTEE.COMMUNICATIONS METROPOLITAINES INC.LA COMPAGNIE DES COIFFEURS ASSOCIES LTEE.LA COMPAGNIE DESPIRT INC.LA COMPAGNIE DE GESTION OMNIA INC.LA COMPAGNIE DE NICKEL & ALLIAGES DES LAUREN-TIDES LTEE LA COMPAGNIE TRANS-SAINT-LAURENT LIMITEE.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Paspébiac.1964 à/to 1973 incl.Ascot Corner.1973 Chicoutimi.1971 à/to 1973 incl.Port-Alfred.1972 et/and 1973 Port-Alfred.1962 à/to 1973 incl.Val Alain.1968, 1970 à/to 1973 incl.Coaticook.1962 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970, 1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1968 incl.et/ and 1973 Montréal.1904, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Michel.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1968 à/to 1973 incl- Papineauville.1970 à/to 1973 incl.Gatineau.1964 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1967, 1971 à/to 1973 incl.Pont-Vian.1961, 1966, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1965, 1972, 1973 Hull.1964 à/to 1973 incl.Duvernay.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine- 1969 à/to 1973 incl.Rivi.'re-du-Loup.196L 1963 à/to 1965 incl 751G QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.61__ Nom de la compagnie Xamc of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed COMPONENT SYSTEMS INC.LE COMPOST DC QUEBEC INC.COMPTOIR ECONOMIQUE DE FONDS MUTUELS LTEE.CONCORDIA INVESTMENTS INC.CONFERENCE DE FOOTBALL INTERMEDIAIRE DE L'EST INC.LE CONGRES DU SPECTACLE INC.CONLOR ENTERPRISES INC.CONSEIL DES LOISIRS DE L'ANCIENNE-LORETTE INC.CONSIM (INTERNATIONAL) INC.CONSTRUCTION BEVAS LTEE.CONSTRUCTION MODIQUE LACHENAIE LTEE.LES CONSTRUCTIONS DEUX MONTAGNES INC.CONTEMPORARY THEATRE.CONTINENTAL VARIETY SALES INC.CONVAR INVESTMENT CORP.CONVENIENT INVESTMENT CORPORATION.COPPER CORPORATION OF AMERICA (NO PERSONAL LIABILITY) COPY CATS INC.CORA PAINTING LTD.CORADMIN INC.CORIM INC.CORPORATION DES CONSOMMATEURS SUCCES INC.CORPORATION DE FINANCEMENT INDUSTRIEL DE PORTNEUF INC.LA CORPORATION DES PROPRIETAIRES D'ETABLISSEMENTS LICENCIES DU QUEBEC INC.COULOMBE ORNAMENTAL IRON WORKS INC.CRATIONS MAY LEONIE LTEE.CREDIT CREMAZIE INC.CREDIT GENERAL INC.CREDIT ST-LAURENT INC.CREDIT VENDOMATIC.CROSS TOWN SALES LTD.CULTURAMA INC.CUMULATIVE INDEX CORP.LOUIS DALLAIRE & 1 ILS LIMITEE.Montreal.'967 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Granby.1960, 1962 à/to 1973 incl.Montréal.I960, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Ancienne-Lorette.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968.1969.1971 à/to 1973 incl.Sorel.1964 à/to 1973 incl.Lachenaie.1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Ville St-Pierre.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Dorval.1964 à/to 1966 incl.1968, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1965 à,to 1973 incl.Donnacona.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1967,1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1963, 1970 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres.1969 à/to 1973 incl.Montrai].1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Xorinaiidin .1958.1967 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7517 Nom de la compagnie Name of the company DARAMONT INC.DARCO INVESTMENT LTD.DAVORE HOLDINGS CORP.MATHIEU DE SOUZA TAILLEUR INC.DELPHI PRODUCTIONS INC.DENMON INC.DES MONTS INC.DESMEULES EQUIPMENT LTD.DEVELOPPEMENT DE GUIRE INC.LES DEVELOPPEMENTS GIFFARD LTEE.DEVOS TUBE & CORE INC.DIAB LTD.DIAMOND HOLDINGS INCORPORATED.DISTRIBEC LTEE.LES DIX.DOLLARD TV SALES & SERVICE INC.DOMAINE CHARLAND INC.DOMAINE COLONIAL INC.DOMAINÉ~DU LAC DES COPAINS INC.LE DOMAINE LAVAL INC.DOMAINE MONT RAINER LTEE.DOMO CONSTRUCTION INC.YVES DUPUIS ET ASSOCIES LTEE.DUVERNAY MARINA INC.E.D.P.COMPUTER SERVICES INC.EDIFICE AMIENS INC.EDIFICE LESSARD LTEE.EDlï VISION INC.EIFFEL COLOGNES INC.ELNA ALUMINUM MFG.INC.ENTERTAINMENT INVESTMENTS INC.L'ENTRAIDE AUX SANS EMPLOI DU QUEBEC INC.ENTREPOSAGE DE FOURRURES LOUISE PELOQUIN INC.LES ENTREPOTS ST-ANDRE LTEE.LES ENTREPRISES BERNARD LIMITEE.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed St-Jean-Baptiste.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Aima.1971 à/to 1973 incl.St-Pie-de-Guirc.1972 et/and 1973 (Juébec.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1966 incl., 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Druminondville.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1937, 1962 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Laurel.1965 à/to 1973 incl.Val David.1965 à/to 1973 incl.Farnham.1962 à/to 196-1 incl.1972 et/and 1973 Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 St-Laurent.1961 à/to 1973 incl.St-Fclix-du-Cap-Rouge.1972 et/and 1973 Laval.1968.1970 à/to 1973 incl.Montreal .1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Jonquii-re.1969 à/to 1973 incl.Lasalle.1973 Mount-Royal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1973 Sorel.1965.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1967, 1969 à/to 1973 incl. 751S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.December 22.1973.Vol.105.Vo.51 Nom de la compagnie Same of the eompany ENTREPRISES BOISJOI.Y INC.LES ENTREPRISES BOLAC INC.LES ENTREPRISES FERNAND BONIN LTEE.LES ENTREPRISES KIMSHA INC.LES ENTREPRISES LEDIT LTEE.LES ENTREPRISES DE L'EPIPHANIE INC.LES ENTREPRISES LIC.A INC.LES ENTREPRISES O.ROLLIN INC.ENTREPRISES OPEN INC.LES ENTREPRISES RAYMOND ARBOl'R INC.LES ENTREPRISES ST-CONSTANT HEIGHTS INC.LES ENTREPRISES ST-ONGE LTEE.LIS ENTREPRISES SAINT-AMABLE INC.LIS ENTREPRISES SEM INC .ENTREPRISES TRANCo INC.ENTREPRISES VIGER INC.ENTRETIEN FLEUR DE LYS INC.ENTRETIEN SELECT INC.LE8 ENTRETIENS HAINS INC.ERTEO LTEE.ESTEHEL CENTRE EQUESTRE INC.LES ESTIMES RENE GUY INC.EXCELUM ALUMINUM PRODUCTS Co.LTD.FEDERATION DES ARCHERS DU QUEBEC.LE FER ORNEMENTAL DE SHERBROOKE INC.LES FERMES BAGATELLES INC.LES FERMES ERNEST CASSER & FILS LTEE_____ LES FIBRES DE VERRE DE L'ESTRIE INC.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Montréal.1964, 1967, 1968, 1970 A/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1073 ind.Beloeil.1959.1961, 1962.1964.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.L'Epiphanie.1963 à/to 1966 incl.1972 et,and 197.1 Montréal.1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Juliette.1972 et/and 1973 La Prairie.1972 et/and 1973 St-Jérôme.1966, 1968 à/to 1973 incl.St-Amable.1972 et'and 1973 Pinrourt.1972 et/and 1973 Jacques-Cartier.I960.1970 à/to 1973 incl.Weatmount.1906, 1970 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Québec.1969 à/to 1973 incl.Lévi.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Cap-Rouge.1970 à/to 1973 incl.Westmount.1971 à/to 1973 incl.Trois-Riviére».1971 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1971 incl.St-Pierre-de-Vérone .1966, 1972, 1973 Lu Guadeloupe.1967, 1970 à/to 1973 incl.Muntreal.1963 à/to 1973 incl.FIDELITY INVESTMENT LTD.FILTERLITE ALUMINUM PRODUCTS LTD.Montreal.1969 à/to 1973 incl.FINCO LIMITEE.Montréal.1971 à/to 1973 incl.FLAMINGO COMMUNITY ASSOCIATION.Montreal.1964, 1971 à/to 1973 incl.FLUORON MONTREAL (EST) INC.Montréal.1965 à/to 1973 incl.D.FORTIN LTD.,«\u201e\u201e,.\u201e.1966 a/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.4M EQUITY DEVELOPMENT INC.Mulltwil,.1966.1968 à/to 1073 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2>.décembre 1973.105' année.it° 51 7519 Nom de la compagnie Same of the company FRANCO CONSTRUCTION LTEE.FRONTENAC AUTOMOBILES INC.Ci.à L.AUTOMOBILE LTEE.(1.M.G.EQUIPMENT INC.C.M.J.MARINE & SPORTS INC.GABLES (INSURANCE AGENCY) LIMITED.GALE LUMBER LTD.GARDA DEVELOPMENT INC.HENRI GAZON INC.GERCLO CONSTRUCTION LIMITEE.GESTION EVA INC.GESTION D'ENTREPRISES COMPTEX INC.GLOMAR JEWELLERS INC.GLOMUS INC.GO UP SALES LTD.THE GOLD CREST PRODUCTS (EASTERN) LTD.GORDON VACUUM CLEANER QUEBEC LTD.GRANATA GARMENT CONTRACTORS LTD.GRAND OLE OPPEY OF CANADA LIMITED.GRAND PRIX CATERING SERVICES INC.GRAVOPLA8TIC INC.HAIG DEVELOPMENT CORP.HAMPSTEAD COMMUNITY SWIMMING POOL CLUB.HELLENIC FOCUS PHILANTROPIC ASSOCIATION INC.FRED HENDY & SON LIMITED.HIGH GRADE FURNITURE CO.LTD.T.HONIGMAN LTD.HORN INVESTMENTS INC.HUDINI LTEE.IMMEUBLE ET PRET G.PERRON LTEK.LES IMMEUBLES BARNABE INC.LES IMMEUBLES BEDFORD INC.LES IMMEUBLES CLARK INC.LE8 IMMEUBLES 1001 ST-DENJS INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1966 a/to 1973 incl.Nantes.1966.1967.1970 a/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1966 à/to 1973 incl.St-Paul-l'Ermite.1970 à/to 1973 incl.St-Hippolyte.1972.1973 Westmount.1959.1961 à/to 1973 incl.Amos.1966, 1970 à/to 1973 incl.St-Michel.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Granby.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1073 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1964, 1965, 1968 à/to 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Noranda.1967, 1969 à/to 1073 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1903 à/to 1906 Incl., 1908 à/to 1973 incl, Hmnpat«id.- 1963, 1966 à/to 1B73 Inol.Montreal.1972 et/and 1973 Lasalle.1967 à/to 1973 incl, Montreal,.19(10 à/to 1973 incl.Ville 8t-Laurent.I960, 1968 à/to 1973 Inol.Montreal.1973, 1973 Ste-Foy.1073 Drummondvllle.1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl, Québec.1968, 1966, 1908 à/to 1973 incl, Montréal.1068, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.,.1963, 1964, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1872, 1973 7520 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December Nom At la compagnie Name of the company IMPRIMERIE GASPESIENNE INC.INDEX PAROISSIAL DES MARCHANDS INC.INDUSTRIAL IRON ORNAMENTS LTD.LES INDUSTRIES ALOUETTE INC.LES INDUSTRIES GARMONT LTEE.INDUSTRIES VANIER INC.INDUSTRIES WARREN INC.INSCOOR LIMITED.INSTANT-PAVE OK CANADA LTD.INTERCONTINENTAL IMPORT INC.INTER-GLOBE LTEE.INTERNATIONAL EQUITY COMPANY LIMITED INTERVILLE CONSTRUCTION INC.ISLEE INVESTMENT LTD.ISOLATION PROVINCIALE INC.J.B.ENTERPRISE LTD.O.K.JACKMAN INC.JALIMON INC.JAMIAN LTEE LA JEUNE CHAMBRE DE CHARLESBOURG INC.JEUNE CHAMBRE DE DAVl'.Ll VVILLE .JOLI COEUR TOURIST ROOM INC.JOLI-COEUR INC.LES JOUVENCELLES DE L'EST INC.JUBILEE QUEBEC HOLDINGS LIMITED.GEORGE KARAISKAKIS ROU.MELIOTIAN SOCIETY OF MONTREAL KARKAJOU AUTO CLUB QUEBEC INC.KEFALONIA VENDING MACHINE CO.LTD.KENNEDY SPORTS INC KINGSWAY PARK GOLF AND COUNTRY CLUB____ L.& G.CLEANING SERVICES LTD.L.& L.CORPORATION LABORATOIRE ESBAY LTEE.LABORATOIRE D'ESSAIS UNIVERSEL INC.LACMA MOTO CLUB INC gg, 1973, Vol.105, No.51 _ Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Mont-Joli.1971 ù/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/lo 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Mari».1968 à/to 1973 incl.Ville Vaiiier.1970 à/to 1973 incl.Québec.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à,to 1973 incl.Montreal .1962.1967 à/to 1973 incl.Montreal .1972.1973 Montréal.1965 à, to 1973 incl.Montreal .I96S.1970 à/to 1973 incl.Longueuil.1965.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Quéhec.1969 à/to 1973 inrl.St-Laurent.1065 »/to 1967 incl.1971 àto 1973 incl.Granby.1972,1973 Montréal.I960 àto 1973 incl.Boucherville.1970, 1972.1973 Charlesbourg.1968 à/to 1973 incl.Daveluj ville.1967 .i i» 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Québec.1971 i;,\u201e 1973 inc| Montréal.1967 à to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal .1969 à/to 1973 in-|.Québec.1968 à,to 1973 incl.Montreal.1971 à.to 1973 incl.St-Romuj|d-d'Etchemin 1972.1973 Lucerne.1972.1973 Montreal.19(17 à/to 1973 incl.Knowlton.1965.1969 à to 1973 incl.Montréal.ri, 1 Montréal.19f,j \u2022 .1967 incl.1071 à.to 1973 incl.*!»\u2022¦ I960 à,to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S£ décembre 1973.105' année.n° 51 7521 Nom de la compagnie Name of the company LAFRENIERE & SONS DEVELOPMENT LTD.LANSDALE HOLDINGS LTD.CONTRAN LATOl'R & FILS INC.THE LAURENTIAN LUMBER COMPANY.LAURENTIDE VACATION HOMES INC.LA LAVANDIERE INC.LAVOIR DU COIN INC.LAVRO INC.LE MANS AUTO INC.LEADER TRADING LTD.LEADS UNLIMITED INC.LEASEBACK LEASING LTD.LEASEHOLD CONTAINERS LTD.G.R.LECOMPTE CONSTRUCTION LTEE.LECROBERINC.LEDO EQUIPMENT & SUPPLY CORP.F.LEVENHECK LTEE.LA LIGUE DES CONTRIBUABLES DE FABREVILLE- LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DU VILLAGE DE L'EPIPHANIE LOCK & KEY SUPPLY CO.LTD.LOCKWOOD ESTATES & INVESTMENT CORP.LES LOISIRS DU LAC CONNELLY INC.LES LOISIRS DE NOTRE DAME DU SACRE COEUR LES LOISIRS ST BERNARD DE SHAWINIGAN INC.LONGCHAMP HAUTE COIFFURE LTEE.LORRAINE LUMBER CO.LTD.G.LORTIE & FILS INC.LUVLINES COMMUNICATORS INC.MACHINERIES LAURENTIDE INC.MAISON JACQUES CORBEIL INC.LA MAISON DU SHISH KEBAB INC.J.G.MARTIN INC.Adresse Address Rapports non produits Returns riot filed Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1972 et/and 1973 Lachute.1932 à,to 1934 incl.1972.1973 Montreal.1966.1972, 1973 Montréal.1964, 1969 à, to 1973 incl.Victoriaville.1961.1966 à,to 1973 incl.Gatineau .1968 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Lachine.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1966 incl.1969 à.to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1969 à/to 1973 incl.Fabreville.1965 à/to 1973 incl.L'Epiphanie.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1970, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à,to 1973 incl.Notre-Dame-du-Sacré- 1965, 1970 à/to Coeur 1973 incl.Shawinigau.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.St-Francois-du-Lac.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Léonard.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Montréal.1962 à/to 1973 incl. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.Deren,h,r 1973.Vol.11)5, So.51 Nom de la compagnie Xamc o/lhe eomjHinu Adresse Address LAWRENCE MASON PRODUCTIONS LIMITED MASS MEDIA LTD.MAVOX INC.MAXWELL ENTERPRISES LTD.MAZALTO INVESTMENTS LTD.MAZCO INC.MC WALL ENTERPRISES LTD.MF.LAB DEVELOPMENT CORPORATION.MERCANT LIMITEE MESA HOLDINGS LTD.LES MESSAGERIES FLEUR DE LYS LTEE METRO COMPUTING SERVICES INC.MEUNERIE ST-FELIX LTEE.MIC (CANADA) LTD.MIDG DE VERDUN.MI LANO LEATHER INC.THE MILK JUG LTD.LES MINES DE FER VAUQUELIN LTEE .(LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) MIRACLE CONSTRUCTION INC.MIRMAN INC.MITIS LIMITEE.MOAL METAL INDUSTRIES LTD.MOCOTT INC.MONETA QUEBEC MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) MONT LAURENTIEN (JASPER) INC.MONTBELLO PROJETS INC.MONTEREY ENTERPRISES INC.MONTOR LANDSCAPE & CONSTRUCTION INC.MONTREAL EPILEPSY SOCIETY.MONTREAL INTERLINE CLUB.THE MONTREAL ISRAELI ASSOCIATION.MONTREAL (MTL) MECHANICAL PRECISION INC.MOORE ENTERPRISES LTD.MORELLATO CONSTRUCTION INC.REAL MORIN INC.Rapports non produits Returns not filed Montreal.1967 a/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Quebec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1959, 1963, 1966, 1970 à/to 1973 incl.Montreal .1967 à/to 1973 incl.Montreal .1966.1967.1970 à/to 1973 incl.Montréal .Montreal.ST-Félix-de-Valois .1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1961.1972, 1973 Québec.1960.1969 à/to 1973incl.Verdun .1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1962, 1972.1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.RJmouaki.1969, 1972, 1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1961.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1972.1973 Montreal.1958, 1965 à;to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.St-Laurent.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7523 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapporta non produits Address Returns not filed Montréal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Marthe-sur-le-Lac .1965 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1967 incl.Laval.1967, 1969 à/to 1971 incl., 1973 Montreal.1961.1962.1964 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Sacré- 1971 à/to 1973 incl.Coeur Lachine.1973 Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Québec.1958.1969 à/to 1973 incl.St-Hermas.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Longueuil.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1966, 190S à/to 1973 incl.Cookshire.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Morin Heights.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962, 1966 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1961.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972,1973 Brossard.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967 à/to 1973 incl.Sillery.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1971, 1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Drummondville.1967, 1970 à/to 1973 incl.A.R.MORISSETTE LTEE.MOTEL DEUX MONTAGNES LTEE.MOTEL-HOTEL FONTAINEBLEAU (CHAMPIGNV) INC.LES MOULINS A SCIE SARRAZIN INC.MOUNTAIN CREST REALTIES INC.MOUVEMENT RECREATIF DE NOTRE-DAME DU SACRE COEUR MOXON (QUEBEC) LIMITED.MUNGER & ASSOCIES LTEE.MURRAY ENTERPRISES INC.D.NEPVEU INC.NETTOYEURS AMBASSADEUR INC.NEW AMALGAMATED ENTERPRISES INC.NORMAND DONUTS LTD.NUMISMATIC INVESTMENTS OF CANADA LTD.NUSAM INVESTMENTS CORPORATION.THE NUT SHELL SHOPPE INC.NUTROFANT LTD.O.G.EQUIPMENT DE BUREAU INC.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE COOKSHIRE INC.OMNITER CORPORATION.ON THE ROUTE INN INC.ONAKEE MINING CO.LTD (NO PERSONAL LIABILITY) .OPERATION MOTIVATION (O.M.) INC.ORBAV REALTY CORP.ORBITAL ENTERPRISES INC.ORESTION FUR CO.LTD.ORMAR INC.OSIRAY DEVELOPMENT CORP.P.E.M.NAVIGATION INC.P.E.8.CORPORATION LTD.P.M.A.REALTY CORP.P.N.ENTERPRISES INC.PANELLINION MEAT MARKET LTD.PATINAGE DE VITESSE DU QUÉBEC INC.PAVAGE VICTORIA INC. 7524 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.December 32.1973.Vol.105.So.51 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produis A'nmr of thr.company Address Returns not filed PERFECTION CONTRACTORS & DECORATORS INC- PHI KAPPA PI MONTREAL ALUMNI CORPORATION LA PHOTO GEANTE INC.PHYSIOTRON INSTRUMENTS CORP.PIERREFONDS HOLDINGS LTD.PINO CONSTRUCTION INC.PI-RON ENTERPRISES INC.ERNEST PITT & SON (QUEBEC) INC.LES PLACEMENTS A.C.INC.LES PLACEMENTS BELLERIVE LTEE.LES PLACEMENTS COMPOSES INC.LF:S PLACEMENTS CONJOINTS INC.PLACEMENTS DIAMOND INC.LES PLACEMENTS DUVERNAY LTEE.PLACEMENTS EPIC (QUEBEC) LTEE.PLACEMENTS ESTRIE INC.LES PLACEMENTS G.T.Z.LTEE.LES PLACEMENTS ISBEN LTEE.PLACEMENTS MATHEGI LTEE.LES PLACEMENTS MERLIN INVESTMENTS LTD.PLACEMENTS MINICO LTEE.LES PLACEMENTS PAU-JAC LTEE.LES PLACEMENTS PRIMA INC.PLACEMENTS DES VINGT INC.PLACEMENTS YAMASKA LTEE.PLOMBERIE GRENON INC.PORT-PLAISANCE INC.PRECAST CONCRETE LIMITED.PRESTON INVESTMENTS LIMITED.PRINCE MEN'S WEAR INC.LES PRODUCTIONS ESSOR LTEE.PRODUIT8 ELECTRONIQUES PONTON INC.PRODUITS METALA LIMITEE.LE PROGRES D'ANJOU INC.PROVINCIAL MOTOR CAR DISTRIBUTORS LTD.DENIS PROVOST & ASSOCIES INC.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal .1972, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1969 à/to 1973 incl Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1968.1970 à/to 1973 incl.Beauport 1973 Jacques-Cartier.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967 àto 1973 incl.Montréal.____ 1963.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1967.1970 à/to 1973 incl.Montréal .1966.1968 à to 1973 incl.Montréal .1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1969 à,to 1973 incl.Montréal.1972.1973 Montréal.1966.1971 à to 1973 incl.Salaherry-de-Valleyfield.1972.1973 Montreal.1971 à.'tn 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 inrl.Montréal 1965 à/to 1973 incl.Montréal .1966.1969.1973 Drummondville.1966.1968 à/to 1973 incl.St-Césaire.1971 à/to 1973 inrl.Laval.1970, 1972, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl, Montréal.1970 à/to 1973 inrl.Montréal.1970.1971,1972 St-Jean.1964 à/to 1973 inrl.Anjou.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1959.1960, 1965 à.to 1973 incl.Lavul.1967 à to 1973 incl. GAZETTE OFFICIEL,.QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7525 Nom de la compagnie Xame of the company PUBLICATIONS PIZZA PUCE INC.425 CONSTRUCTION INC.QUEBEC ALUMETAL INDUSTRIES INC.QUEBEC MOLV MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) QUEEN MARY PASTRY & DELICATESSEN INC.H.G.ALUMINIUM INC.KELIX RACICOT INC.RAINBOW COSMETICS AND DRUG CO.LTD.REAL ESTATE CONSULTANTS OP CANADA LTD.REINA CONCESSIONS INC.RENAISSANCE GENERAL CONTRACTORS INC.LES RESIDENCES BONA VENTURE.RESTAURANT APOLLO INC.RESTAURANT LA CREOLE INC.RESTAURANT MAISON INC.RESTAURANT LE TUNNEL INC.RESTAURANT-O-RAMA INC.RESTAURANT-TABAGIE ST-DENIS INC.REVETEMENTS PERMANENTS DU QUEBEC INC.REVETEX INC.REX CONSTRUCTION CO.LTD.RIALTO PAVING CO.LTD.MAURICE RICHARD T.V.LTEE.RIPANO CO.LTD.RIVA REALTY INC.RO ENTERPRISES INC.ROLARTIC MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).ROSEMOUNT TAXI ENTERPRISES LTD.ROSWEIL REALTY CORPORATION.ROUTHIER ET FRERES INC.CYRILLE ROY INC.S.A.G.SPORTSWEAR INC.ARTHUR 8T-GERMAIN LTD.ST-JACQUES ET WATKINS INC.ST.LAWRENCE LEASEHOLD CORPORATION.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Quebec.1972.1973 St-Bruno-de-Montarville 1963 4/to 1973 incl.Montreal.1967 A/to 1973 incl.Val-d'Or.1962.1970, 1971.1973 Montreal.1964 A/to 1973 incl.Rouyn.1970 A/to 1973 incl.Sorel.1970 à/to 1973 incl.Chomedey.1963 à/to 1973 incl.Westmount.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-Michel.1968 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Verdun.1959 A/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1960, 1965 A/to 1973 incl.St-Miche!.1966, 1969 A/to 1972 incl.Montreal.1971, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1965, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Québec.1968 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl. 7526 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 1973.Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse A ddress Rapports non produits Returns not filed ST.MORITZ HAUTE COIFFURE INC.ST.REGIS PAVING & SUPPLIES LTD.SABOURIN ENTERPRISES LTD.SALON DE COIFFURE PENELOPE INC.SALON JANNOTTE INC.SALON MANON INC.SALON YO-LA LIMITEE.SANTA-CRUZ GARDENS INC.GERARD SAUCIER LIMITEE.SECRETARIAT GAUTHIER INC.N.SEGUIN TRANSPORT INC.SEIGNIORY PARK COUNTRY CLUB.SEKA IMPEX CO.LTD.SELECT ENTERPRISES INC.SERVICE DE CONGELATION TRANS QUEBEC INC.SERVICE FINANCIER ALOUETTE INC.SERVICE DES LOISIRS ST-THEOPHILE-DE-LAVAL .SERVICE DES LOISIRS STE-JEANNE-D'ARC.SERVICE MARITIME COULOMBE LTEE.LES SERVICES GRAPHIQUES P.G.INC.SERVICES JEUNESSE DE L'EST.SHERMAN ENTERPRISES INC.SHOP EZE (1966) INC.SI MICHAELS SHOES INC.SIGN ERECTION HARDWARE LTD.SKI ORFORD INC.SNOW WHITE REFUSE COLLECTION AND DISPOSAL LTD SOCIETE CANADIENNE DE RECUPERATION ET DE COMPOSTAGE LIMITEE SOCIETE FRONTENAC LTEE.SOCIETE G.N.G.TURBIN INC.SOCIETE DE GESTION 804 INC.LA SOCIETE N.RAINVILLE LTEE.SOCIETE DE PLACEMENT TRIANGLE INC Montreal.1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1969 à/to 1973 incl.St-Joachin-de- 1959.1963, 1967, 1969.Châteauguay 1973 Jonquière.1972, 1973 St-Michel.1965.1970 à/to 1973 incl.Rouyn.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Val d'Or.1966, 1973 Laval.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967.1969 à/to 1973 incl.Châteauguay.1963.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Verdun.1967 à/to 1973 incl.St-Théophile-de-Laval.1964 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Québec.1972.1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Greenfield Park.1965.1969, 1970, 1972, 1973 Montreal.1944, 1954 à/to 1961 incl., 1965, 1973 Cap-Santé.1949, 1970 à/to 1973 incl.Canton d'Orford.1961, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Brosaard.1964 à/to 1973 incl.St-Léonard.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1969 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' aimée, ;i° 51 7527 Nom de la compagnie .Yame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LA SOCIETE DE PLACEMENTS IN VEST A LTEE.LA SOCIETE PRODUCTION ETOILE INC.SOCIETE DE PROMOTIONS V.T.T.INC.SOUVENIRS L.A.T.LTEE.STERE-O-VISION INC.STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE QUEBEC INC.STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE STE-FOY INC.STUDIO PHOTO OFFSET INC.SUNNY ISLAND DEVELOPMENT CORP.SUPERIOR TRADING INC.MAURICE TABAH DE SOREL INC.TABAH SHOES & HANDBAGS MANUFACTURING INC.TAVERNE DAGENAIS INC.TERRA NOVA ENTERPRISES LIMITED.THETFORD VEND-O-MATIC LTEE.THREE WAY ENTERPRISES COMPANY LIMITED.TIMKO-GOUIN HOLDING CORPORATION.TINDARY'S FISH MARKETS LTD.GEORGES TOUTEN INC.LA TRAFONTAINE LIMITEE.TRAICAR INC.TRANS-CANADA URBAN DEVELOPMENT CORP.TRANS-CITY INVESTMENT CORP.TRANSPORT BELLE-VALLEE LTEE.TRANSPORTS LEBLANC INC.V.TRIPODI AND SON LIMITED.TRI-SERVICE HOLDINGS LTD.LE TROUSSEAU ECONOMIQUE INC.S.D.TURCHEK CONSTRUCTION LTD.TWIN DEVELOPMENT CORPORATION.TWOBEE TRADING LTD.TYPOTRONIC INC.Montréal.1963 à.to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Chambly.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1972, 1973 Ste-Foy.1972.1973 Montréal.1964, 1966 à,to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1941,1972,1973 Joliette.1972,1973 Joliette.1972.1973 St-Michcl.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à.to 1973 incl.Thettord Mines.1972, 1973 Montreal.1904.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à.to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1956.1961 àto 1964 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1965 incl.1970 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1969 à/to 1973 incl.Bonaventure.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1968 incl-, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Michel .1968 à/to 1973 incl. 752S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973.Vol.105, Np.51 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of the company Addrcu Returns not filed UNION CONSERVATORY OF MUSIC INC.Montreal.196\".1909 a/to 1973 incl.UNION CYCLISTE DU QUEBEC INC.Québec.I960, 1964, 1965, 1966, 1969 a/to 1973 incl.UNITY IMPORT SALES CO.LTD.Montreal.1966 a/to 1973 incl.CNIVEND INC.Mont Royal.1968 à/to 1973 incl.V.& V.AUTO BODY SHOP LTD.Montreal.1971 à/to 1973 incl.VAL KILKENNY INC.Laval.1972.1973 VALBOIS INVESTMENT CORP.Montreal.1968 à/to 1973 incl.VALMA CONSTRUCTION INC.Amqui.1968 à/to 1970 incl., 1972.1973 VALO INC.Québec.1968 à/to 1973 incl.VAUDREUIL GUN CLUB INC.Dorion.1971 à/to 1973 incl.VENEZIA GARDENS LTD.Montreal.1971 à/to 1973 incl.VERCHERES ORE-OIL CORPORATION (NO PERSONAL Victoriaville.1965 à/to 1973 incl.LIABILITY) VERDUN INDUSTRIAL CENTRE LTD.Verdun.1965.1966.1968 à/to 1973 incl.LES VETEMENTS KEBEC INC.Québec.1968 à to 1973 incl.VEZINA & FILS LTEE.Waterville.1967 a/to 1973 incl.VICANN INC.Montreal.1969 à/to 1973 incl.VICINITY DEVELOPMENT CORP.Montreal.1959 à/to 1973 incl.VILLARS LUMBER LTD.Val d'Or.1962, 1964, 1966, 1968 à/to 1973 incl.V1LLEROY CONSTRUCTION INC.Montreal.1964.1966 à/to 1973 incl.V'IMAR INC.Montreal.1971 à/to 1973 incl.VINCOR INC.Esterel.1965 à/to 1973 incl.VISA COMMUNICATIONS LIMITED.Montreal.1970 à/to 1973 incl.VISCOUNT LEASING CORPORATION.Montreal.1968 à/to 1973 incl.VITAL BOUCHER INC.Leclercville.1970 à/to 1973 incl.VYNDA PRODUCTS LTD.Montreal.1966, 1968 à/to 1973 incl.WARSHAW INVESTMENTS LTD.Montreal.1969 à/to 1973 incl.WATERMATIC QUEBEC LTD.Québec.1968 à/to 1973 incl.WEBER IMPROVED MACHINERY LTD.Montreal.1962, 1966 à/to 1073 incl.WEISS ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY.Montreal.1970 à/to 1973 incl.WELDWALL CORPORATION LIMITED.Montreal.1965 à/to 1973 incl, WEST ISLE AUTOMOBILE WHOLESALERS LIMITED.Montreal.1971 à/to 1973 incl.WESTERNOFF CO.LTD.Montra.1964, 1070 à/to 1973 incl.WESTMERE ESTATES INC.Montreal.1968,1972.1973 ERIC WIELE AGENCIES INC.Montreal.1970 à/to .973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 38 décembre 1973, 105' année, n° 51 7529 Nom de la compagnie A'amc of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed THE WIG BOUTIQUE INC.WILSON GARDEN AGENCY INC.WINANT ENTERPRISES LTD.WOODBRIDGE FURNITURE LTD.WORLD WIDE ENGINES INC.WUNDIES OF CANADA LTD.Y.G.L.CONSTRUCTION LTEE.YAC-TAC ENTERPRISES INC.M.A.YALE oV ASSOCIATES LTD.YORK.MONT INVESTMENT CORPORATION YUSEV INC.ZENITH REALTIES CO.LTD.ZORBAS RESTAURANT INC.ZULIA ENTERPRISES (QUEBEC) LIMITED.Montreal.1966 A/to 1973 incl.Montreal.1962 A/to 1973 incl.Montreal.1968 A/to 1973 incl.Montreal.1965 A/to 1973 incl.St-Lambert.1965 A/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967 A/to 1973 incl.Gatineau.1965 A/to 1973 incl.Montreal.1967 A/to 1973 incl.Montreal.1970 A/to 1973 incl.Montreal.1962, 1963, 1965 A/to 1973 incl.Montreal.1967 A/to 1973 incl.Montreal.1964 A/to 1973 incl.Montreal.1971 A/to 1973 incl.Montreal.1967 A/to 1973 incl.Le directeur du service des compagnies.55210-o Pierre Desjahdins.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées A compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.55210-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gaiette of this second notice.Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Incorporation Date AIRD EQUIPMENT LIMITED.ALLIED CRANE SERVICES INC.ALLIED HOLDING COMPANY' LIMITED.ALPINE INN LIMITED.AMEUBLEMENT LALIBEHTE INC.LES AMIS DE L'OPERA INC.LES AMIS DE PHILIPPE HAMEL.LES AMIS DES SCOUTS DE BAIE COMEAU.AMIS DES SCOUTS DE CHICOUTIMI INC.AMOCO CONSTRUCTION INC.AMYOTTE GARAGE LIMITED.SAM E.ANDREWS INC.ANDRIAN SOCIETY OF MONTREAL.Hudson Heights.\t29\t11\t1955 \t20\t11\t1964 \t06\t11\t1969 \t08\t11\t1947 St-Hyacinthe.\t11\t03\t1970 Québec.\t22\t03\t1968 Montréal.\t20\t11\t1962 \t07\t04\t1966 \t10\t02\t1969 \t03\t06\t1963 Village de Fort Coulonge\t16\t11\t1953 \t27\t09\t1948 \t23\tD2\t196S 7530 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Montréal.09 12 1970 Montreal.24 02 1967 Montréal.09 12 1968 Montreal.19 10 1961 Anjou.31 05 1966 Laval.28 04 1967 Montreal.21 12 1964 Anjou.29 11 1966 Montreal.28 03 1963 Danville.26 04 1956 Montreal.19 10 1961 Cap-de-la-Madeleine.12 05 1969 Cap-de-la-Madeleine.29 10 1959 Ville St-Laurent.13 06 1932 Sherbrooke.06 05 1971 Levis.18 12 1963 La Pocatiere.16 09 1964 Boucherville.16 04 1970 Ancienne-Lorette.13 12 1960 Québec.04 10 1965 Chicoutimi.13 06 1966 Longueuil.17 01 1969 St-Sauveur-des-Monts ,-.06 11 1959 Paspébiac.11 09 1968 Sherbrooke.12 02 1968 Montreal.25 10 1967 Montreal.06 02 1964 Rouyn.28 03 1963 Rimouski.12 08 1958 Montreal.13 04 1960 Black Lake.11 03 1971 Canton Delisle.07 12 1961 Dolbeau.06 01 1966 Montreal.10 08 1970 Ste-Catherine-de-Hatlev 01 06 1970 ANGLO-CANADIAN INVESTMENT GROUP LIMITED.ANGLO-FRENCH ENTERPRISES INC.LES ANIMAUX CANADIANA INC.ANITA'S INC.ANJOU GOLFORAMA INC.LES ANNONCES PUBLICITAIRES G.M.CARON INC.ANNOR CORP.LES ANNUAIRES PRATIQUES INC.ANSAM HOLDINGS CORPORATION.ASBESTOS EXPRESS LIMITEE (LIMITED).ASSOCIATED INDUSTRIAL DRAUGHTSMEN SERVICES INC.L'ASSOCIATION AGE D'OR SAINT ODILON.L'ASSOCIATION AMBULANCIERE CATHOLIQUE.L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE DE ST LAURENT INCORPOREE ASSOCIATION DES ANCIENS DU SEMINAIRE DE SHERBROOKE.ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE LA RIVE SUD.ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DU COLLEGE STE ANNE DE LA POCATIERE L'ASSOCIATION QUEBECOISE DE COUREURS AUTOMOBILES SUR TERRE (L.A.Q.C.A.T.) INC ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ANCIENNE LORETTE INC.ASSOCIATION SPORTIVE DES DEBARDEURS DE QUEBEC INC.L'ASSOCIATION DE TRANSPORT D'ECOLIERS SECTION SAGUENAY LAC ST JEAN INC AU VENT D'ORGE INC.AUBE EQUIPMENT COMPANY LIMITED.AUBERGE DU PARC LTEE.AUTO CLUB 1600 INC.BELGIAN FOOD ENTERPRISES INC.BEN-RAY CONSTRUCTION LTD.BERGERON BOAT HOUSE LIMITED.BERTIN & FILS LTEE.BLUE BIRD ANNOUNCEMENT INC.BOIE MONTMORENCY INC.LEONCE BOUCHARD & FILS LTEE.BOULEVARD DEBOSSAGE & PEINTURE LIMITEE.BOURENDERINC.BOUSCON INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105' année.n° 51 7531 Nom de la compagnie Name of the company BOUTIQUE JULIENNE INC.LA BRASSERIE D'ANJOU INC.BRASSERIE L'OASIS INC.BRAZIL GEM STONES CORP.BREAD BASKET INTERNATIONAL LTD.BETTY BRITE LTD.BRUCHESI, BAZINET & CIE LTEE.BUILD-FAST STRUCTURES LTD.BUREAU D'INFORMATION PROFESSIONNELLE DE MONTREAL INC CAFE AN-RO LTEE.CAMIONNAGE LEGAULT LTEE.CANADIAN JEWISH THEATRE FOUNDATION INC.CANADIAN MUSICAL INDUSTRIES LTD.CASA BELLA FURNITURE INC.CASPER MOTOMOBILE CLUB INC.CAVERNE LAFLECHE INC.CENTRAL ROOFING INC.CENTRE D'AMENAGEMENT INTERIEUR INC.CENTRE D'ESCOMPTE DEGUIRE INC.LE CENTRE D'HUILE ST MICHEL INC.CENTRE D'INFORMATION SPECIALISE INC.CENTRE DES LOISIRS DU GRAND DESERT INC.LE CENTRE DES LOISIRS ST JEAN DE LA CROIX.LE CENTRE RECREATIF DE LA PAROISSE DE STE JEANNE D'ARC LEVIS INC CENTRE DE VOILE DE L'ESTRIE.LES CF;NTRES DE CONVERSATION FRANÇAISE ET ANGLAISE DE MONTREAL INC CHARLEVOIX VIDEO INC.LE CHATEAU DOLBEAU LIMITEE.CIE IMMOBILIERE DE CHOMEDEY LTEE.LA CIE D'IRRIGATION TOLHURST LTEE.LA CIE DE PETROLES LEMAY LTEE.CIRCUIT MONT ST ANDRE INC.CITE AUTOMOBILE LIMITEE.CLINIQUE DE SANTE NATURELLE (MONTREAL) INC.LE CLUB AUTO-NEIGE DE PRINCEVILLE INC.CLUB AUTO-NEIGE ST ANDRE AVELLIN.Adresse Incorporation Address Date Montreal.06 07 1970 Anjou.20 03 1968 Sept-Iles.04 08 1971 Montreal.07 12 1965 Montreal.10 02 1971 Montreal.11 11 1963 Montreal.23 12 1971 Montreal.22 03 1968 Montréal.12 08 1970 Lachine.10 01 1962 Hull.25 05 1970 Montreal.31 08 1971 Montreal.20 06 1961 Montreal.29 12 1970 St-Félicien.14 09 1970 Pointe-aux-Trcmbles .10 09 1958 St-Laurent.07 10 1959 Ste-Foy.22 11 1968 Montreal.25 08 1971 St-Michel.13 07 1959 Montréal.04 03 1969 Ancienne-Loretta.13 12 1960 Petite Rivière.23 01 1962 Levis.11 11 1958 Sherbrooke.01 04 1971 Montréal.25 06 1970 BaieSt-Paul.20 06 1957 Dolbeau.26 10 1966 Chomedey.01 02 1962 Vimont.15 05 1965 Pont Viau.12 12 1963 St-André-Avellin.23 05 1967 Chicoutimi.05 01 1966 Montréal.25 08 1970 Princeville.24 10 1969 St-André-Avellin.09 02 1970 7532 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date CLUB DE CROQUET DE DRUMMONDVILLE.LE CLUB ELDO INC.CLUB DE LA FERME STE THERESE.LE CLUB HANDICAP INC.CLUB DE HOCKEY JUNIOR DE WATERLOO.CLUB JAVELIN AMX DE QUEBEC INC.CLUB LAURENTIEN DE SKI NAUTIQUE.LE CLUB NAUTIQUE DE TROIS-RIVIERES OUEST INC.CLUB 4-D.LE CLUB RECREATIF CANADIEN.CLUB RICHELIEU QUEBEC.LE CLUB DE SKI DE STE ANGELE DU MONT-JOLI.CLUB SOCIAL DE FERME-NEUVE INC.CLUB SPORTIF LA POCATIERE.CLUB DE TIR NEMROD INC.LES COFFRAGES DU QUEBEC LTEE.LE COMITE DES AMIS ET PROTECTEURS DES SCOUTS CATHOLIQUES DE GRANBY INC COMITE DES LOISIRS PAROISSE ST LUCIEN (SAINT JEROME! INC .LA COMMISSION DES LOISIRS DE FORESTVILLE INC.LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DESERY.COMPAGNIE D'OPTIQUE PROVINCIALE.CONSEIL REGIONAL D'EXPANSION ECONOMIQUE DE LA GASPESIE ET DES ILES DE LA MADELEINE CONSTRUCTIVE REALTIES LTD.LA CORPORATION DE GAZ SAGUENAY LAC ST JEAN LTEE.CORPORATION D'IMMEUBLES & D'HYPOTHEQUES DE QUEBEC INC CORPORATION DE LA NATIVITE.LA CORPORATION DES OBLIGATIONS EUROPEENNES LIMITEE.C.COTE & FILS LIMITEE.LA CREMERIE DE LACHUTE LTEE.D.M.D.INTERNATIONAL INC.D.S.D.CONSTRUCTION INC.LES DAMES AUXILIAIRES DU FOYER DES ANNEES D'OR DE KENO-GAMI INC DART MARKETING SERVICES LTD.DAVID & GARTH ENTERPRISES LTD LUCIEN DAVID & FILS INC.Drummondville.12 12 1956 Rock Forest.28 01 1964 Fabreville.19 05 1964 Magog.12 09 1966 Waterloo.17 10 1963 Québec.28 04 1970 Ste-Agathe-des-Monts .01 06 1961 Trois-Rivières.04 03 1966 Montréal.16 06 1961 Malartic.27 11 1963 Québec.28 01 1953 Mont-Joli.07 01 1969 Ferme-Neuve.19 03 1968 Ste-Anne-de-la- 26 10 1962 Pocatière St-Augustin-de- 20 08 1971 Desmaures Montréal.04 09 1968 Granby.16 04 1963 St-Jérome.11 02 1963 Forestville.11 11 1968 Montréal.16 01 1934 Montréal.12 02 1969 Gaspé.19 07 1963 Montreal.13 01 1960 Chicoutimi.26 02 1960 Ste-Foy.29 09 1965 Shawinigan.08 09 1960 Montréal.16 05 1921 Chandler.18 07 1960 Lachute.01 03 1940 Montréal.01 10 1965 Les Saules.17 04 1968 Kénogami.12 05 1970 Montreal.27 04 1960 Montreal.07 04 1971 Montréal.26 02 1965 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 106' année, n° 61 7533 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Address Date DAVIGNON ENTERPRISES INC.\t\t04\t06\t1969 \t\t13\t06\t1968 DECOR RAILINGS INC.\t\t17\t03\t1966 \t\t31\t07\t1967 DECTRONICINC.\t\t.22\t10\t1970 DEL GRANDE SHOE SALON INC.\t\t03\t10\t1960 DELAG TRADING LIMITED.\t\t02\t09\t1970 DELEPINE-LESTANG INC.\t\t29\t07\t1958 DELICATESSES JAKO INC.\t\t07\t09\t1971 \t\t29\t09\t1961 \t\t\t68\t1966 LES DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS DE STE-FOY INC.\tSte-Foy.'.,\t12\t03\t1963 \t\t12\t08\t1964 DIFFUSION ET PROMOTION D'INFORMATIONS (D.P.I.) INC.\t\t02\t09\t1968 \t\t21\t08\t1961 DIPLOME CONSTRUCTION INC.\t\t24\t02\t1965 \t\t09\t12\t1969 \t\t19\t10\t1967 LES DISTRIBUTEURS D'OEUFS DE ST FRANÇOIS-DU-LAC.\tSt-F'rançois-du-Lac.,\t.19\tOS\t1970 LE DOMAINE DE L'ANSE VERTE INC\tBerthier-en-Bas.\t01\t09\t1961 \t\t07\t12\t1967 ANDRE DUPUIS & FILS LIMITEE.\t\t29\t06\t1962 EAST ANGUS SPORTSWEAR LTD\t\t15\t09\t1966 LES EDITIONS D'ANJOU LTEE\t\t14\t03\t1969 \t\t05\t02\t1965 LES EMPLOYES FORESTIERS DE LA ROUGE INC.\t\t11\t07\t1963 EMPRESS LOUNGE & DINING ROOM INC.\t\t23\t08\t1961 \t\t28\t05\t1968 \t\t02\t04\t1959 \t\t06\t06\t1962 \t\t14\t01\t1966 \t\t01\t04\t1971 \t\t15\t11\t1968 \t\t28\t04\t1970 \t\t20\t01\t1965 \t\t24\t07\t1959 \t\t22\t02\t1961 7534 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 22.1973, Vol.105.No.51 Nom de la compagnie Name of the company LES ENTREPRISES DES MILLE ILES LIMITEE ENTREPRISES MT TREMBLANT LTEE.LES ENTREPRISES NADON LTEE.LES ENTREPRISES REVERIE INC.LES ENTREPRISES TOUR BELLEVUE INC.LES EQUIPEMENTS ROG-AN LIMITEE.LA FEDERATION REGIONALE DES LIGUES DE PROPRIETAIRES DU SAGUENAY LAC ST JEAN LES FILMS DELTA INC.FLAMBOYANT DECORATIONS INC.FONDERIE GINGRAS INC.J.E.FORGET CORPORATION LTEE.FOROCOINC.ANDRE FORTIN SERVICE STATION INC.FORTY TWO LTD.FORUM HARDWARE STORES LTD.FOURNIER .v FRERES LTEE.FRANCE BEAUTE INC.FRANKLION REALTY LIMITED.FRENCHSTYLE LTD.FRUITERIE NOTRE-DAME-DES-ANGES LTEE.PAUL GAMACHE INC.GARAGE LEO TROTTIER LTEE.GARAGE MAURICE GIRARD LTEE.GARDE STE TRINITE DE CONTRECOEUR INC.GARLAND STONE LTD.GAZ NATUREL RACHEL INC.LA GESTION MONTREUX LTEE.GLOBAL BROADLOOM INDUSTRIES INC.CAMERON GRANT INC.LES HABITATIONS FAMILIALES DE ST BRUNO LTEE.HABITATS INTEGRES INC.D.HAREL IMPORT LTD.H ATARI WILD ANIMAL CORPORATION.HOME PROTECTION DEVICES INC.HOTEL REVERIE INC.HOTELLERIES D'ANJOU INC.Adresse Incorporation Address Date St-François.27 08 1964 Mont Tremblant .29 06 1961 Laval.09 09 1966 Montréal.03 05 1966 Montréal.24 02 1972 St-Augustin-de- 05 05 1969 Desmaures Arvida.08 03 1960 Montréal.13 02 1964 Montréal.11 08 1969 Québec.11 02 1965 Montréal.15 06 1964 Sept-Iles.22 12 1971 Laval.31 03 1966 Montreal.14 01 1959 Montreal.05 04 1960 Jacques-Cartier.14 12 1965 Duberger.18 01 1968 Montreal.29 10 1959 Montreal.15 03 1957 Montréal.15 02 1968 Joliette.31 12 1953 Montréal.10 10 1959 Joliette.20 12 1959 Contrecoeur.15 05 1968 Montreal.22 04 1969 Montréal.18 06 1969 Montréal.16 11 1964 Montreal.08 09 1967 Montreal.09 04 1943 St-Bruno-de-Montarville 15 09 1965 Montréal.23 04 1970 Montreal.29 01 1068 Montreal.02 12 1968 Montreal.24 04 1959 Montréal.11 08 1966 Montréal.23 07 1966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105- année, n- 51 7535 Nom de la compagnie Name of Ihe company Adresse Incorporation Addrett Date Montreal.23 10 1968 Valois.14 08 1968 Hull.20 01 1964 Laval.29 01 1971 Giffard.29 12 1961 < \"in- oui inn.22 07 1964 Val-David.22 02 1965 Montréal.14 01 1971 Montréal.14 03 1967 Montréal.18 08 1967 Price.03 06 1966 Montréal.13 06 1965 Montreal.21 09 1966 Joliette.22 01 1960 Montreal.10 02 1960 Montreal.22 08 1060 Montréal.30 10 1970 Montréal.22 10 1965 Montreal.16 11 1966 Montreal.14 12 1970 Montréal.29 06 1959 St-Luc.13 01 1972 Sherbrooke.26 05 1970 St-Léonard.28 04 1970 Montréal.27 01 1960 Montreal.03 02 1064 Montreal.31 08 1970 St-Tite.24 02 1960 Québec.03 01 1963 Montréal.27 12 1967 Montreal.22 01 1971 Montréul.14 12 1059 St-Laurent.08 07 1970 Montréal.21 05 1964 Boucherville.16 04 1970 Sherbrooke.04 11 1003 Montreal.16 12 1968 THE HOUSE OF MUSIC INC.HUETT GARAGE LTD.HULL-OTTAWA WOOD PRODUCTS LIMITED.I.D.O.SPORTS INC.LES IMMEUBLES LA NOUVELLE ORLEANS INC.LES IMMEUBLES MASSON LTEE.LES IMMEUBLES VAL DAVID LTEE.L'IMPRIMERIE ROBERT & FILS LTEE.INDUSTRIE ILI CORPORATION.LES INDUSTRIES R.M.INC.INSTITUT BEAULIEU INC.INSTITUT 222 INC.INTERNATIONAL COINAGE CORPORATION.INTERNATIONAL DEVICES INCORPORATED____ INTERNATIONAL DIAMOND RING LTD.INTERNATIONAL DRILLING LIMITED.INVENTER LTEE.INVESTISSEMENTS LABRADOR INC.ITALIA ASSOCIATES LTD.J.P.8.ELECTRONICS INC.LES JARDINS NAPIERVILLE INC.LES JARDINS DE ST LUC INC.JARIC LTEE.JAYCEE DEVELOPMENT CO.LTD.JEAN AUTOMOBILE INC.JEAN PIERRE ORIGINALS LTD.JERANA FASHIONS LTD.LE JEUNE COMMERCE DE ST-TITE INC.MARIE ANGE JOBIN INC.JOCELVN DECOR INC.DAVID JOHNSTON & CO.INC.JONCAS FOURRURES INC.JOROGEMOBE CORPORATION LTD.KARA-VAN TRANSPORT LTEE.KEBECON CONSTRUCTION INC.KING-OUEST TIRE RECAP INC.KIPP PAPER COMPANY LTD. 7536 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Name of the company KIWANIS CLUB OF LAKE OF TWO MOUNTAINS.KNICKERBOCKER SOCIAL CLUB LTD.K-WAH RESTAUR ANT INC.L.B.P.INC.L.& V.SHOE INC.LABARGIL INC.LABELLE ET FILS AMEUBLEMENT INC.LABORATOIRE CHARLES-ALAIN LTEE.LACQUER PRODUCTS CO.LTD.LAGTJEUX & DESROCHERS LIMITEE.LAKE FINANCE CO.LTD.LAMONTAGNE COMMERCIAL EQUIPMENT LTD.LAN CAFE INC.LANDBERT REALTY CO.L'ANGELIQUE DISCOTHEQUE INC.LANTHIER EXPRESS LIMITEE.ANDRE LAPIERRE AUTOMOBILE LTEE.LAVAL DINNER LTD.LIBRAIRIE COSMOS LIMITEE.LA LIBRAIRIE NOUVELLE LIMITEE.LES LOISIRS DU PLATEAU INCORPORE.LOISIRS SAINT JEROME INC.LOISIRS DE STE ANNE DE BELLEVUE.LONG ISLAND LAND CORP.LUCERNE DRESS (1968) INC.LUXOR MILLINERY LTD.LES LYNX DE NICOLET INC.MAISONS & CHALETS PLAISANCE INC.MAISON D'EDITION H.M.INC.MAISON JONQUILLE INC.LA MAISON DES SOUHAITS INC.MANUFACTURE MONTCALM LIMITEE.LE MARCHE AUX PUCES DE SAINT REMI DE NAPIERVILLE INC.MARCHE AUX PUCES DE SHERBROOKE.MARINA L'ANSE AUX SAULES INC.MARINA DU RICHELIEU INC.MAROCO LTEE.Adresse Address Incorporation Date Dorion.20 09 1955 Montreal.28 12 1929 Montréal.18 07 1963 Tring Jonction.08 04 1968 AylmerEst.08 08 1961 Montreal.04 01 1971 Montréal.14 03 1963 Montréal.12 08 1964 Montreal.25 01 1947 Québec.11 05 1926 Lachine.29 07 1960 Québec.30 04 1958 Montréal.15 06 1970 Montreal.16 05 1958 Québec.08 11 1968 St-Polycarpe.14 10 1933 Repentigny.18 07 1962 V.St-François.01 12 1960 Laval.10 03 1968 St-Jérôme.08 07 1968 Chicoutimi.08 10 1963 St-Jérôme.27 10 1949 Ste-Anne-de-Belleviie .26 04 1960 Montreal.22 04 1958 Montreal.13 02 1968 Montreal.28 10 1955 Nicolet.14 09 1960 L'Ancienne Lorette.28 05 1969 Montréal.14 07 1971 Montréal.11 09 1963 Montréal.04 12 1964 Joliette.03 02 1967 Montréal.13 09 1971 Sherbrooke.07 10 1963 St-Joseph-de-Chambly.17 05 1962 Carignan.23 09 1971 Québec.19 03 1964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SB décembre 1973.105- année, n° 51 7537 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Alma.14 01 1905 Marieville.01 03 1966 Montreal.23 07 1966 Montréal.09 12 1969 Cowansville.11 06 1965 Montreal.30 06 1967 Alma.29 11 1956 Montréal.12 02 1971 Verdun.29 05 1969 Montréal.08 03 1971 Montreal.19 12 1951 Montreal.20 10 1965 Montreal.19 07 1971 Montreal.28 12 1970 Montréal.06 04 1966 Sacré-Coeur.10 06 1960 St-Adolphe-d'Howard.11 05 1966 Montréal.Il 09 1964 Jonquiére.,.05 08 1966 Montreal.26 10 1961 Montreal.24 07 1067 Miatassini.02 02 1966 Sherbrooke.21 10 1965 Ste-Cathertne- 24 09 1968 d'Alexandrie-de-Laprairie St-Léonard.la 10 1965 Montréal.18 06 1971 Montréal.31 05 1971 Montreal.13 02 1968 Montreal.,, 31 07 1958 Montreal.,,,, 09 06 I960 Montreal.07 04 1967 Montréal.19 01 1970 Montréal., 80 08 1966 Montréal.,,,,, 31 09 1867 Montreal.,.21 11 1966 Montreal.24 12 1958 MATERIAUX DE CONSTRUCTION SAG UEN A Y LTEE.JOCELYN MAYNARD INC.MAZEL EQUIPMENT INC.MEDITOURS LTEE.MERCERIE MR SIMON INC.MERIT BUILDING CORP.M ES Y CONSTRUCTION INC.MEUBLES JACQUES LAPIERRE INC.MIKE'S DELICATESSEN AND SUPERMARKET INC.LA MODE INTRIGANTE DU QUEBEC INC.MONTREAL LEATHER & SHOE FINDING CO.LTD.MONTREAL USED CARS INC.MONTROIL RESOURCES LIMITED.MONTROIL RESOURCES LTD.MORIN TRAITEMENT D'EAU LTEE.MOTEL ETOILE INC.MOTEL LA LEGENDE INC.MULTI SPORT INC.MULTIFEU INC.MUSIC UNLIMITED CORPORATION.MY MARKET OF MONTREAL INC.MYRAY CONSTRUCTION LTEE.N.CONSTRUCTION INC.NADRA ET CIE LTEE.NANWAH RESTAURANT INC.NANWAH RESTAURANT (1971) INC.NAPA LTEE.NAPOLI REALTIES INC.NATIONWIDE REALTIES LTD.NATJEAN REALTIES LTD.NAXIAN SOCIETY OF MONTREAL.NELLO PIZZERIA INC.N ETAS EC INC.NET-CO NETTOYEURS LIMITEE-.NEUMA SUB SOIL PIERCING LTD.NEVA DEVELOPMENT LTD. 7538 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date NEWTOWN INVESTMENT CORPORATION.NIETSPIL SPORT CENTRES INC.NORMANDIE AUTOMOBILE LTD.NORVID INVESTMENT CORP.NORWOOD DISTRIBUTORS LTD.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE KINGSEY FALLS INC.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-PAULIN DALIBAIRE.OLYMPIA BOWLING INC.O'NEIL & RICHARD LIMITEE.OPTION JEUNESSE.OVERSEAS TRADING AND FINANCE COMPANY LIMITED.PARAMOUNT DELICATESSEN (STE-THERESE) INC.PATISSERIE ET DELICATESSE ST-JEAN LTEE.LE PATRO SAINTE ANNE INC.PAVAGE NOEL INC.PAYETTE & PAYETTE ROTALITH INC.PENGOR MACHINE PARTS LTD.PERRON & FILS LTEE.PERRON & FRERES CONSTRUCTION INC.LE PETIT CHEZ NOUS INC.LES PETROLES VICTORIA INC.PICARD CINSTRUCTION INC.PIERCON LTEE .PIZZA PAN (DECARIE) LTD.PLACE FLEUR-DE-LIS SHOPPING DISTRICT INC.PLACEMENTS ALOUETTE INC.PLACEMENTS ANIK LTEE.LES PLACEMENTS BEL-RIVE INC.LES PLACEMENTS COTE LAPOINTE INC.PLACEMENTS DE FOY INC.PLACEMENTS KEBEC INC.LES PLACEMENTS REGENT LTEE.LES PLACEMENTS ST-JUST-MALMONT LTEE.N.PLAMONDON AUTO LTEE.POALE ZEBEC FREE LOAN ASSOCIATION.RENE POIRIER TRANSPORT INC.PONT VIAU FOUNDRY LIMITED.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Kingsey Falls.St-Paulin-Dalibaire.Sept-Ues.Québec.Trois-Riviéres.Montreal.Ste-Thércse.Québec.Ste-Anne-des-Monts Amos.St-Jean.St-Laurent.Montréal.Laval.Montréal.Victoriaville.Montréal.Drummondville.Westmount.Québec.Montréal.Montréal.Salaberry-de-Valleyfield.Chicoutimi.Ste-Foy.Montréal.Montréal.Montréal.Montréal.Montreal.St-Félix-de-Valois.Pont-Viau.19\t08\t1957 30\t11\t1970 04\t07\t1955 03\t06\t1971 23\t04\t1951 25\t07\t1962 04\t01\t1964 07\t09\t1961 09\t07\t1941 14\t08\t1970 11\t12\t1947 02\t02\t1971 05\t03\t1969 19\t07\t1963 13\t05\t1963 23\t10\t1952 14\t11\t1966 26\t11\t1947 08\t09\t1967 13\t08\t1968 31\t07\t1964 23\t11\t1965 01\t09\t1966 13\t10\t1970 26\t01\t1960 02\t02\t1970 01\t04\t1968 01\t12\t1960 28\t04\t1960 13\t12\t1967 10\t06\t1965 27\t10\t1971 24\t08\t1970 M\t08\t1963 16\t09\t1936 27\t05\t1968 os\t07\t1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105- année, n° SI 7539 Nom de la compagnie Name of the company PORT ROYAL TOOL & DIE INC.PRODUCTION EQUIPEMENT AMPUMATIC LTD.PRODUCTION SERVICES INC.LES PRODUCTIONS YVES ANDRE INC.LES PRODUITS FORESTIERS A.B.LTEE.PROMOTION ANJOU INC.PROPRIETAIRES DE TAXIS DE MONTREAL INC.PYRO-PROTECTION INC.QUEBEC BRINE COMPANY LIMITED.QUEBEC TERRA INVESTMENT CORPORATION.RAPHAEL 67 (QUEBEC) INC.LA RENAISSANCE NATIONALE DU QUEBEC.RENAUD REFRIGERATION INC.RESTAURANT BROSSARD INC.RETAPROP CORPORATION.LA REVUE DES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS.RICHELIEU MACHINE SHOP & WELDING INC.ALEX ROCHON TRANSPORT LIMITEE.ROLIC CIE LTEE.ROMO & FILS INC.ROSS-SMITH (1969) LTD.S.R.C.INC.ST ANDREW'S TRANSPORT CO.LTD.ST FRANCIS MARINA INC.ANDRE ST-GELAIS INC.ST HUBERT FABRICS INC.ST PIERRE & DESJARDINS INC.STE ANNE AUTO WASH INC.SAFEWAY FARM EQUIPMENT CO.LTD.SALAISON DU NORD INC.SALAISONS RIVE SUD INC.SALON ASTRID LIMITEE.SANDS MUSIC INC.SERVICE D'AFFAIRES UNIQUES INC.SERVICE D'ENTRETIEN DUVERNAY LIMITEE.SERVICE D'INFORMATION HRL INC.SEVILLE DELICATESSEN & PASTRY INC.Adresse Address Incorporation Date Montreal.30 08 1969 Montreal.14 06 1968 Montréal.29 09 1954 Trois-Rivières.30 12 1968 Lac-au-Saumon.01 12 1950 Montréal.21 01 1969 Montréal.10 06 1965 Montréal.01 04 1971 Sillery.16 07 1971 Montreal.05 10 1959 Montréal.13 05 1968 Montréal.01 09 1965 Hauterive.05 06 1968 Brossard.29 03 1967 Montreal.12 07 1963 Montréal.31 03 1966 Sorel.13 02 1967 Montréal.18 03 1966 Montréal.25 01 1968 St-Ignace-de-Stanbridge.09 12 1966 Verdun.29 12 1964 Montréal.27 01 1969 St-Eustache.05 04 1961 St-Anicet.14 07 1965 Montréal.06 02 1968 Montreal.23 04 1971 Hauterive.02 05 1966 Québec.09 03 1960 St-Césaire.01 02 1960 Montréal.21 02 1967 Brossard.22 07 1971 Montréal.31 01 1951 Montreal.01 09 1967 Montréal.08 03 1962 Laval.05 08 1970 Québec.30 12 1964 Montreal.02 02 1966 7540 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 32, 1973.Vol.106, No.51 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date SHU LA INVESTMENTS LTD.SMILING JACK'S STEAK HOUSE LIMITED.LA SOCIETE DES AMIS DE DANIEL JOHNSON.LA SOCIETE ANONYME DE PLACEMENTS INC.SOCIETE MINIERE D.M.D.INC.LA SOCIETE DU MONT SAINTE AGATHE INC.SOUDURE SEPT-ILES INC.SOUND FINANCE AND INVESTMENT LIMITED.'.SOURCES PASTRY SHOP 4 DELICATESSEN INC.SPEECH AND HEARING SOCIETY OF THE PROVINCE OF QUEBEC.STATION QUATRE-BOURGEOIS INC.SUPER M PRODUCTIONS INC.SYLVIE VINGT ANS INC.SYNDICAT D'INITIATIVE TOURISTIQUE DES LAURENTIDES (NORD DE MONTREAL).Montreal.Montreal.St-Pie.Montréal.Québec.Ste-Agatlie-des-Monts.Sept-Ilea.Montreal.Peirrefonda.Montreal.Ste-Foy.Montréal.Québec.Ste-Agathe-des-Monts.FRANCO TELATIN & FRERES LIMITEE.TELECABLE SAGUENAY INC.TELE-METS INC.THEATRE DE L'ANSE INC.TIIETFOHD TECHNO INC.M.THIBODEAU LTEE.TOUT-NET SERVICE INC.TRANSCONTINENTAL MINERALS LTD.JEAN GUY TREMBLAY LTEE.TREVI LAND CORPORATION.TUBEC INC.L'UNION CIVIQUE LAUREN TIENNE INC.L'UNION MUSICALE DE THETFORD INCORPOREE.UNIVERSAL WASTE MATERIALS INC.VALVE IN VOLUME CORP.LES VENTES NICO INC.8t.Pa.cal.J.A.VERREAULT TRANSPORT INC.Québec.VIC A JACqUES (ALMA) INC.Aima.VILLA MUSICA INC.Trol.-Rlvlére., VINET & LAGAOE STREETS DEVELOPMENT ASSOCIATION.Dorvol.LA VOIX DE LA CANADIENNE INC.Montréal.VOYAGEUR GASPESIEN LIMITEE.Mont-Joli Montréal.Chicoutiml.Montréal.Vaudreuil.Thetford-Mine».Montréal.St-Romuald-d'Etrhemin Montreal.Montréal.Montreal.Montréal.Oraainville.Thetford-MInea.Montreal.Montreal.01\t05\t1958 10\t12\t1957 II-,\t03\t1969 N\tIIS\t1962 M\t11\t1967 16\t10\t1971 10\t13\t1968 30\tM\t1958 24\t10\t1968 ni\t08\t1955 27\t02\t1967 16\t07\t1970 31\t01\t1969 33\t01\t1967 M\t13\t1964 11\t03\t1972 26\tos\t1066 03\to:,\t1993 24\tM\t1968 DU\tn\t1992 14\to:,\t1966 28\t07\t1967 28\t03\t1963 03\t11\t1969 37\ton\t1972 il,\ton\t1966 ta\t11\t1938 06\t04\t1066 Kl\ton\t1966 07\t08\t1969 18\t12\t1962 13\t08\t1969 33\t10\t1905 27\t03\t1966 11)\t12\t1963 11\t\t1969 GAZETTE OFF ICI ELL.QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n\" 51 7541 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date WEST ISLAND DELICATESSEN RESTAURANT INC.WESTWOOD CADILLAC MINES LIMITED.ZAR METAL PRODUCTS INC.Pointe-Claire.24 10 1966 Montreal.15 09 1936 Montreal.27 09 1966 552I0-o Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.55210-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (1™ partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: -pcrating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ABATTOIR LAROCHE INC.ACIER TECHNI LTEE.TECHNI STEEL LTD.AGENCE DE VOYAGES GREFFE INC.ALIMENTATION BOISCHATEL INC.ARCAND & FILS INC.ASSURANCE AIME DARVEAU INC.ASSURANCES FOLEY INC.J.P.AYOTTE INC.LIONEL BLAIS & FILS INC.BOUTIQUE DE SANTE ET BEAUTE LI-BO LTEE.LI-BO HEALTH AND BEAUTY BOUTIQUE LTD.BOUTIQUE RAMSES II INC.RENE BRETON INC.CENTRE DE SECRETARIAT DE LONGUEUIL INC.CENTRE DE THERAPIE RESPIRATOIRE DE LA MAU-RICIE INC.J.M.CHAMPAGNE & FILS INC.CONSTRUCTION DENIS RI VEST INC.DENIS RI VEST CONSTRUCTION INC.Asbestos.12 10 73 95, rue Scaron, Auteuil, Laval.22 11 73 1760, boulevard des Laurentides, 30 10 73 Laval.5166, avenue Royale, Saint-Jean-de- 21 11 73 Boischatel.Saint-Jérôme.24 10 73 860, Pierre de L'Estage, Berthierville.26 10 73 128, rue Principale, Saint-Stanislas.08 11 73 3240, Des Erables, Tracy.29 10 73 Saint-Elzéar.15 11 73 444, Jean Talon Street West, Montreal 07 11 73 5, Chemin Trudel, Notre-Dame-des- 08 11 73 Laurentides.Saint-Michel, (comté de Bellechasse).16 11 73 85, rue St-Charles ouest, Longueuil.01 11 73 Trois-Rivières.12 10 73 Saint-Honoré.26 10 73 40, rue Denis, Repentigny.20 11 73 7542 Nora / -Vamc QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105.A'o.51 Incorporation Date CONSTRUCTION LEMEGO LTEE.LEMEGO CONSTRUCTION LTD.CONSULSPOR INC.CORD ENTERPRISES INCORPORATED.LES ENTREPRISES CORDE INCORPOREE.CORPORA INC.CORPORATION D'AMENAGEMENT MAPLE CRESCENT.MAPLE CRESCENT DEVELOPMENT CORP.LA CORPORATION DE RECHERCHES INDUSTRIELLES PACIFIQUE INC.PACIFIC INDUSTRIAL RESEARCH CORPORATION INC.HENRI D'AOUST LUMBER, QUEBEC LTD.MATERIAUX HENRI D'AOUST, QUEBEC LTEE.DOMAINE AUX QUATRE VENTS LTEE.FOUR WINDS ESTATES LTD.DUPUIS & GUERTIN INC.LES ECURIES V.I.P.INC.V.I.P.STABLES INC.LUCIA ENRICO GARAGE d GENERAL REPAIRS INC.GARAGE 4 REPARATIONS GENERALES LUCIA ENRICO INC.LES ENTREPRISES AQUA BLEU LTEE.LES ENTREPRISES BERIAULT-PERREAULT INC.EQUIPEMENT DERAGON INC.DERAGON EQUIPMENT INC.LES EQUIPEMENTS MARMEN LTEE.LES ETABLISSEMENTS ORANORE INC.EXCAVATION GAGNON 4 LAPOINTE INC.F AU BERT FEED INC.MOULEES FAUBERT INC.THEODE FORCIER 4 FILS INC.G.M.OVERSEAS TRADING CO.LTD.COMPAGNIE DE COMMERCE D'OUTREMER G.M.LTEE.GAGNON 4 SIMARD INC.GARAGE PIERRE MIGNEAULT (PORT CARTIER) INC.GOODLEAF ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES GOODLEAF INC.MAURICE GOUGEON 4 FILS INC.GRAFOTO INC.LES HABITATIONS G.L.M.INC.Montréal.16 11 73 6600, Kildare Street, Apt.907, Côte- 20 11 73 Saint-Luc.2049, Harvard, Montréal.12 10 73 Drummondville.'0 H 73 Montréal.OS 11 73 2015, Drummond Street, Suite 202, 01 11 73 Montreal.Chemin de la Savane, Pointe-Gatineau 04 09 73 Saint-Constant.03 10 73 Montréal.15 10 73 Québec.U 10 73 7162, Vannes Street.Saint-Léonard.19 11 73 Beloeil.20 11 73 Québec.29 10 73 Pike River.16 11 73 157.Lorette, Cap-de-la-Madelcine____ 02 11 73 580, Grande-Allée est, suite 140, 23 10 73 Québec.Dolbeau.08 11 73 Huntingdon.21 08 73 Saint-Gérard.20 11 73 4850, Côte St.Luc, Suite 47, Montreal.26 10 73 261.Terrasse Lebrun, Repentigny.16 08 73 Port-Cartier.19 11 73 Caughnawaga.22 11 73 Sainte-Béatrix.05 11 73 Rue Pointe Langlois, Sainte-Rose.16 11 73 Laval.59, 9e Avenue ouest, Vimont, Laval.16 11 73 Siège social / Head Office GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7543 Nom / A'ame LES HOTELS CHEZ-SOI INC.ANDRE HUOT INC.LES IMMEUBLES NEVERS LTEE.LES INVESTISSEMENTS LES DRAVEURS LIMITEE.JIDEL INC.KERR.CRIPPEN.ROY & ASSOCIES.INC.KERR, CRIPPEN, ROY & ASSOCIATES, INC.LABORATOIRE TECHNIQUE QUEBEC INC.MARC-AURELE LUSSIER INC.MELEGO LTEE.MELEGO LTD.MEVIL INC.GILBERT P.MILLER & FILS LTEE.GILBERT P.MILLER & SONS LTD.LES NOUVEAUX ENSEMBLES URBAINS LIMITEE.PERSONNEL D'URGENCE QUEBEC INC.EMERGENCY PERSONNEL QUEBEC INC.P.PICHETTE & FILS INC.LES PIECES D'AUTOMOBILES LEON GRENIER INC.LEON GRENIER AUTO PARTS INC.PLACE FLEURIMONT INC.PLA NI-TRANSPORT INC.POITRAS & POITRAS LTEE.POTVIN.BROCHU.GOULET & ASSOCIES INC.POTVIN.BROCHU.GOULET & ASSOCIATES INC.QUINCAILLERIE ALBANEL LTEE.ALBANEL HARDWARE LTD.RENOVER INC.RESSOURCES EST OUEST LTEE.EAST WEST RESOURCES LTD.RESTAURANT LES CHEVALIERS DU TASTE-VIN INC.ROGER ROBERT ET FILS INC.ROGER ROBERT AND SON INC.SACS A MAINS LAURENTIENS LTEE.LAURENTIANS HANDBAGS LTD.STANLEY SAWKA INC.SERVICE DE CHAUFFAGE ROBERT INC.LES SERVICES PRET ET REVENU LTEE.THE SAVINGS AND INVESTMENT SERVICES LTD.Incorporation Siège social / Head Office Date Mont-Tremblant.09 11 73 1521, rue Richard, Rainte-Foy.31 10 73 Québec.14 11 73 Hull.26 06 73 80, Brookside, Beaconsfield.02 10 73 1203, IBM Building, 5, Place Ville- 16 11 73 Marie, Montréal.2050, rue Mansfield, Montréal.17 10 73 Route 209, (Saint-Antoine-Abbé), 24 10 73 Franklin.Montréal.16 11 73 Québec.29 10 73 Arundel.06 07 73 Montréal.27 11 73 2075, Dickson, Sillery.27 11 73 305, rue Montigny, Saint-Jérôme.16 11 73 205, boulevard Paquette, Mont- 02 11 73 Laurier.Sherbrooke.16 11 73 Québec.08 11 73 614, rue Vincent, Beloeil.15 11 73 7245, Alexandra Street, Mont real.22 11 73 Granby.02 11 73 6061-63, boulevard Robert, Saint- 02 11 73 Léonard.9993, Pie IX, Montréal.02 11 73 621 Craig Street West.Suite 400, 14 11 73 Montreal.1175, rue Mackay, Montréal.03 12 73 Saint-Bruno-de-Montarville.26 11 73 3615A, St.Lawrence Boulevard, 08 11 73 Montreal.Galerie Taschereau, Boulevard Tas- 26 11 73 chereau, Greenfield Park.210, rue Berthiaume, Contrecoeur .21 11 72 Québec.23 11 T.PONTOS LEATHER GARMENTS CO.LTD.COMPAGNIE DE VETEMENTS DE CUIR PONTOS LTEE. 7544 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date SOCIETE DE GESTION N.A.I.LTEE.LES SPECIALITES ORSAINVILLE INC.STUDIO WILLIS CHICOUTIMI INC.SYLVITEC INC.LES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION G.C.INC .G.C.TELECOMMUNICATION SYSTEMS INC.TRANSPORT DUBEN INC.DUB EN TRANSPORT INC.TRANSPORT L.L.B.INC.TRANSPORT REAL INC.REAL TRANSPORT INC.101.de la Savane, Sainte-Anne-des- 15 11 73 Monts.2119, rue des Bouvreuils, Orsainville.31 10 73 449, rue Racine est, Chicoutimi.22 11 73 2835, Chemin Gomin, Sainte-I'oy.15 11 73 7101, Musset, Saint-Michel.31 10 73 Laval.14 11 73 1908, Nice, Laval.22 11 73 Saint-Nicéphore.19 11 73 55210-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55210-o Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Lettres patentes (3' partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ASSOCIATION DES TECHNOLOGISTES FORESTIERS DU QUEBEC ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DU COLLEGE DE VALLEYFIELD LA CLINIQUE JURIDIQUE POPULAIRE DE HULL INC.CLUB DE L'AGE D'OR DE CLARENCEVILLE.CLARENCEVILLE GOLDEN AGE CLUB CLUB DE L'AGE D'OR ST-VINCENT DE PAUL DE LAVAL.CLUB DE MOTONEIGE DE ST-ROBERT INC.CLUB DE PLONGEE OTARIE INC.CLUB MOTO-NEIGE FRELIGHSBURG INC.CLUB RUITER BROOK (1973) INC.RUITER BROOK CLUB (I97S) INC.COMITE DU CENTENAIRE DE ST-ELEUTHERE INC.CONSEIL DES AFFAIRES MUNICIPALES DE L'EST DU QUEBEC INC.COSMIC INITIATION CENTER.CENTRE INITIATION COSMIQUE Québec.25 10 73 169, Champlain, Valleyfield.19 10 73 Hull.09 08 73 Clarenceville.17 11 73 Saint-Vincent de Paul, Laval.08 11 73 Saint-Robert-Bellarmin.05 11 78 635, Parc des Roulottes, Roberval____ 16 11 73 C.P, 33, Frelighsburg.05 02 73 Mansonville.09 11 73 Saint-Eleuthère.05 11 73 Riinouski.20 03 73 5109 St.Laurent Boulevard, Montreal 16 11 73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7545 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date FEDERATION DES EQUIPES LACORDAIRE ET DES Grand Séminaire.Cité Universitaire.23 08 73 EQUIPES CARREFOUR DE SOBRIETE DU QUEBEC Sainte-Foy (F.E.L.E.C.Q.) GARDE LES BOULES INC.Les Boules.14 11 73 GARDE ST-VICTOR DE MATANE INC.Petite-Matane.14 11 73 MACKAY SPECIALTIES LIMITED.3500 Decarie Boulevard.Montreal 22 08 73 LES SPECIALITES MACKAY LIMITEE 55210-0 Le directeur du service dee compagnies, Pierre Desjardins.55210-o Pierre Desjardins.Director of the Companies Service, Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: Companies Act.he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes ASSURANCES MICHEL BROSSEAU LTEE.13 00 57 MICHEL BROSSEAU ASSURANCES LTD.CENTRE DE SKI ET DE RECREATION CHATEAU BLEU INC.12 03 71 CLUB RAQUETTEURS FRONTENAC.12 09 62 COB CO.LTD.17 05 72 LES COURTIERS M.P.INC.15 03 72 LES ENTREPRISES CHAMPOUX INC.16 08 41 19 10 73 LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE.LES ENTREPRISES D.D.A.INC.D.D.A.ENTERPRISES INC.LA GARDE DU SACRE-COEUR D'ALMA INC.08 05 69 29 05 73 30 03 65 18 10 73 1) Ancien nom / Former name: DU CREST ET BROSSEAU ASSURANCES LTEE 2) Modifiant le nombre de ses administrateurs / Changing the number of directors 14 02 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant.les privilèges et restrictions/ Modifying the privileges and restrictions 09 10 73 Modifiant la valeur des biens immobiliers/ Modifying the value of immoveable property 13 08 73 Modifiant le capital / Altering the capital 11 10 73 Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters potent 1) Ancien nom / Former name: LAURENTIDE AUTOMOBILE INC.(1951) 2) Etendant les pouvoirs / Extending the powers 08 11 73 Etendantlespouvoirs/.ExtrndinffMff pouiers 20 11 73 Etendant les pouvoirs /Extending the powers 13 11 73 1) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 3) Modifiant la valeur des biens immobi- liers / Modifying the value of immoveable property 7546 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 32, 1973, Vol.105, No.51 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes LES INDUSTRIES DALLAIRE LTEE.16 08 DALLAI RE INDUSTRIES LTD.JANIC DISTRIBUTION INC.30 09 PIERRE LEGAULT INC.:.05 10 LE SERVICE DES LOISIRS DU PARC DES LAURENTIDES VACHON INC.17 03 17 71 28 11 73 Confirmant le compromis ou arrangement / Confirming the arrangement 63 15 10 73 Etendant les pouvoirs / Extending the powers 65 15 11 73 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes/ Amending the provisions of the letters patent 1) Ancien nom / Former name: CLUB DES LOISIRS DE L'ETAPE INC.2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 11 73 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent 02 10 72 17 09 73 2s Le directeur du service des compagnies, 55210-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 55210-0 Director of the Companies Service.Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Name\tIncorporation Dissolution Date Date A-l CHEMICALS LTD.CITY SURPLUS INC.DELAURO INC.HEBERT INVESTMENT LTD.HOLMBY HOLDINGS INC.IMMEUBLES FINLAY' INC.LICO INVESTMENTS LTD.LIVERANT BROS.LTD.MAJOR APPLIANCE SERVICE INC____ SERVICE D'APPAREILS MAJOR INC.MEGA LIMITED.METRODISC INCORPORATED.MOLON CORPORATION.LEOPOLD MONDOU LTEE.NORCO LTD.PAULCOR HOLDINGS INC.31\t03\t58\t28\t12\t73 30\t01\t61\t21\t12\t73 22\t08\t68\t28\t12\t78 09\t01\t67\t28\t12\t73 04\t01\t63\t28\t12\t73 29\t12\t67\t28\t12\t73 02\t04\t69\t28\t12\t73 14\t11\t38\t21\t12\t73 20\t05\t65\t28\t12\t73 23\t09\t64\t28\t12\t73 29\t10\t62\t28\t12\t73 29\t01\t66\t28\t12\t73 27\t10\t61\t28\t12\t72 28\t09\t66\t28\t12\t73 27\t12\t67\t28\t12\t73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7547 Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date B.PERREAULT SERVICE STATION INC.\t19\tni\t60\t21\t12\t73 POVRELLE DRESSES & SPORTSWEAR INC.ROBES & VETEMENTS SPORT POURELLE INC.\t08\t04\t70\t21\t12\t73 \t\t12\t62\t28\t12\t73 SALON VIATEUR LTEE.\t17\t04\t64\t28\t12\t73 SERVICES SPECIALISES VILLE-MARIE INC.VILLE-MARIE SPECIALIZED SERVICES INC.\t11\t01\t65\t28\t12\t73 \t\t12\t63\t28\t12\t73 SPRING GROVE DEVELOPMENT CORP.\t01\t12\t66\t28\t12\t73 STUTMAN & YOUNG HOLDINGS LTD.\t27\t01\t69\t28\t12\t73 55210-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.5521O-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Avis de correction (Lettres patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction des lettres patentes des corporations ou compagnies suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Siège social Nom / Name H ead office\tIncorporation Modification Date Corrections DESRON INC.Notre-Dame-du-Lac.04-10-73 remplaçant le nom / replacing the nam-\"RONDES INC.\" par le nom/by th« name \"DE8RON INC.\"\t Le directeur du service des compagnies, 55210-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 55210-0 Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a approuvé les règlements de changement de nom suivant:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the r.ame of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date AUTOMOBILE LAJOIE & NERON LTEE.LAJOIE &HUDON AUTO- 13 05 68 LAJOIE & NERON AUTOMOBILE LTD.MOBILE LTEE LA BOUTIQUE L'ENSEMBLIER INC.G.LEBEL LTEE.28 10 69 CREATIONS MARIE-CLAUDE (1973) INC.AURELE LACROIX INC.02 08 61 DORAIS CONSTRUCTION INC.DORAIS^LUSSIER CONS- 29 04 72 7548 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 23, 1973, Vol.105, No.61 Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date \t.PAUL MORENCY INC.07 12 61 \t \tANDRE CLAUDE INC.04 06 68 WOLFE STREET FOOT CLINIC INC.LA CLINIQUE DU PIED RUE WOLFE INC.\t.WOLFE STREET FOOT CLINIC.17 09 62 INC.Le directeur du service des compagnies, 55210-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 65210-o Director of the Companies Service.Fusion de compagnies\tAmalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Siège social Name of new company Head office\tFusion Nom des compagnies Amalgamation fusionnées Names of companies Date amalgamated LES IMMEUBLES ELECTRA INC.1500 Atwater Avenue.09 10 73 DURWARD INVESTMENTS LTD.ELF.CTRA REALTY INC.Montréal.ELECTRA REALTY CORP.GALE REALTIES & DEVELOPMENT CORP.METCALFE CONSTRUCTION-CO.LTD.ROB ROY INVESTMENTS LTD.ROWENA INVESTMENTS LTD.STEREO INVESTMENTS INC.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 55210-o Pierre Desjardins.55210-o Director of the Companies Service.Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications Joseph Gaétan Jacques Crandmaison Avis est donné par les présentes que Joseph Gaétan Jacques Grandmaison, chauffeur, du 3407 est, rue Ontario, Montréal, Québec, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil demandant le changement de son nom en Joseph Gaétan Jacques De Grandmaison, conformément aux dispositions de la Loi du changement de nom._ Ladite requête doit affecter sa femme, Dame Pierrette Chartrand, et ses enfants: Marie Huguette Muguette Carmen De Grandmaison.Joseph Marcel Yvon De Grandmaison, Marie Huguette Pierrette Sylvie De Grandmaison.Montréal, le 29 novembre 1973.Le procureur du requérant, 55088-50-2-o Me Hahoi.d C.Leiirer.Joseph Gaétan Jacques Grandmaison Notice is hereby given that Joseph Gaétan Jacques Grandmaison, chauffeur, of 3407 Ontario Street East, Montreal.Québec, intends to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council requesting the change of his name to Joseph Gaétan Jacques De Grandmaison, pursuant to the provisions of the Change of Name Act.The said petition is to affect his wife, Dame Pierrette Chartrand and his children: Marie Huguette Muguette Carmen De Grandmaison, Joseph Marcel Gaétan Y'von De Grandmaison, Marie Huguette Pierrette Sylvie De Grandmaison.Montreal, November 29, 1973.Mtbe Harold C.Leiirer, 55088-50-2-o Attorney for petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105' année, n' 51 7549 Johann Rudolf Dossegger Avis est donné que Johann Rudolf Dossegger.gérant, domicilié et résidant au 085.boulevard Graham, cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Rudolph Doseger.Montréal, le 29 novembre 1973.Le» procureurs du requérant.55I22-50-2-o Bernier & Boucher.Johann Rudolf Dossegger Notice is given that Johann Rudolf Dossegger, manager, domiciled and residing at 685.Graham Boulevard, City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Rudolph Doseger.Montreal.November 29th.1973.Bernier & Boucher, 55122-50-2-o Attorneys for the applicant.Marie Thérèse Bofficc Avis est par les présentes donné que Marie Thérèse Boffice, femme d'affaires, de la Cité de Montréal-Nord, district de Montréal, province de Québec, et demeurant au 12315 rue Lapierre, app.5, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille de Boffice à Alfieri.Les procureurs de la requérante, Robinson, Sheppahd.Borenstein, 55086-50-2-o Shapiro & Flam.Marie Thérèse Boffice Notice is given that Marie Thérèse Boffice.Businesswoman, of the City of Montreal-North, Province of Québec, therein residing at 12315 Lapierre Street, Apt.5, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorisation to change her surname from Boffice to Alfieri.Robinson, Sheppard.Borenstein, Shapiro & Flam.55086-50-2-o Attorneys for petitioner.M > i i.im Boffice Avis est par les présentes donné que Myriam Boffice, étudiante, de la Cité de Montréal-Xord, district de Montréal, province de Québec, et demeurant au 12315 rue Lapierre, app.5, adresse une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour l'autoriser à changer son nom de famille de Bofficc à Alfieri.Les procureurs de la requérante, Robinson, Sheppard, Borenstein.55087-50-2-o Shapiro & Flam.Myriam Boffice Notice is given that Myriam Boffice.Student, of the City of Montreal-North, Province of Québec, therein residing at 12315 Lapierre Street, Apt.5, is making application to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for authorization to changer her surname from Boffice to Alfieri.Robinson, Sheppard, Borenstein.Shapiro & Flam, 55087-50-2-o Attorneys for petitioner.Alfred Walczewski Nous donnons avis que Alfred Walczewski, étudiant, domicilié et résidant au numéro 3641, boulevard Saint-Laurent, ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Alfred Walsh; ce changement de nom devant également bénéficier à l'épouse du requérant, née Janet Davidowicz, domiciliée au même endroit.Saint-Jean, le 29 novembre 1973.Les avocats du requérant, 55089-50-2-O Cahtier & Favreau.Alfred Walczewski Notice is hereby given that Alfred Walczewski, student, domiciled and residing at 3641 St.Lawrence Blvd., city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his name to Alfred Walsh; such change to benefit his wife, born Janet Davidowicz, domiciled and residing at the same place.Saint-Jean, this November 29.1973.Cartier & Favreau, 55089-50-2-o Attorneys for petitioner.Jacques St-Martin Avis est par les présentes donné que M.Jacques St-Martin et M.Michel St-Marlin, résidant à 139 Louis-Hébert, Hull, feront une demande au lieutenant-gouverneur en conseil afin que leur nom soit changé en celui de Jacques Sarrazin et Michel Sarrazin.1$ procureur du requérants, 55261-51-2-o Guy Lepage, arocal.Jacques St-.Martin Notice is hereby given that Mr.Jacques St-Martin and Mr.Michel St-Martin, residing at 139 Louis-Hébert, Hull, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing their names to Jacques Sarrazin and Michel Sarrazin, respectively.Guv Lepage, lawyer, 55261 -51 -2 Attorney for the applicants. 7550 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 France Tremblay Avis est par les présentes donné que France Tremblay, résidant au 3,500 Aylmer, appartement 5, Montréal 130, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à François Tremblay.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Chicoutimi, le 21 novembre 1973.Les avocats du requérant, Roy, Yaillancourt 55149-50-2-o & Tremblay.Steven Paul Meyer Avis est donné que Steven Paul Meyer, étudiant, demeurant à 125 Ballantyne.Xord, Montréal-Ouest, P.Q.fera une requête auprès du ministre de la justice afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Steven Paul Johnson.Montréal, le 11 décembre, 1973.Les procureurs du requérant.McLean, Marler, Fefs, 55260-51-2-0 Watson et al.Marie Thérèse Charlotte Boivin Avis est donné que Marie-Thérèse-Charlotte Boivin, veuve d'Emmanuel Cocke, de 1900 Lincoln, appt.98, Montréal, demandera au ministre de la justice la permission d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Marie-Thérèse-Charlotte-Natalie Boivin.Les procureurs de la requérante, 55221-51-2-0 McLean.Marler, Tees et al.France Tremblay Notice is hereby given that France Tremblay, residing at 3,500 Aylmer Street, apt.5, Montreal 130, district of Montreal, will petition the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his name to François Tremblay.This change will not affect any person else than the applicant.Chicoutimi, November 21, 1973.Roy, Vaillancourt & Tremblay, 55149-50-2-o Attorneys for applicant.Steven Paul Meyer Notice is given that Steven Paul Meyer, Student, residing at 125 Ballantyne, North, Montreal-West, P.Q., will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to that of Steven Paul Johnson.Montreal, December 11, 1973.McLean, Marler, Fees, Watson et al., 55260-51-2-o Attorneys for the petitioner.Marie Thérèse Charlotte Boivin Notice is given that Marie-Thérèse-Charlotte Boivin, widow of Emmanuel Cocke, of 1900 Lincoln, apt.98, Montreal, shall apply to the Minister of Justice for a decree changing her name to Marie-Thérèsc-Charlotte-N'atalie Boivin.McLean, Marler, Tees et al, 55221-51-2-0 Attorneys for the Petitioner.Abel Rivier Avis est donné que Abel Rivier, artisan, résidant et domicilié au 39} 2 de la rue Racine, Loretteville, district de Québec, s'adressera au ministre de la justice afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Gaétan Lavoie, conformément aux dispositions de la Ix)i de changement de nom (S.Q.1965.chapitre 77).Québec, ce 20 novembre 1973.Le procureur du requérant, 55223-51-2-o André Cloutier, avocat.Abel Rivier Notice is given that Abel Rivier, craftsman, residing and domiciled at 39J^ Racine Street, in Loretteville, District of Québec, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to that of Gaétan Lavoie, in conformity with the provisions of the Change of Name Act (Q.S.1965.Chapter 77).Québec, November 20, 1973.André Cloutier, lawyer, 55223-51-2- Attorney for the applicant.Yolande Thibaudeau Avis est donné par les présentes que Y'olande Thibaudeau, commis, des ville et district de Montréal, et résidant au numéro 2810, Prieur est, appartement 2, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Carmen St.Pierre, en vertu des dispositions de la Loi du changement de nom, 13-14 Elizabeth II, chapitre 77.Fait à Montréal, ce 21e jour de novembre 1973.Les procureurs de la requérante, 55271-51-2 Khonish & Zilbert.Yolande Thibaudeau Notice is hereby given that Yolande Thibaudeau, clerk, of the City and District of Montreal, and therein residing at 2810 Prieur East, Apt.2, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for an order changing her name to Carmen St.Pierre under the provisions of the Change of Name Act, 13-14 Elizabeth II, Chapter 77.Dated at Montreal this 21st day of November 1973.KrONISII & ZlLBERT, 55271-51-2-0 Attorneys for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, «g décembre 1973, 105' année, n° 51 7551 Joseph Henri Maurice Pierre Parent Avis est donné par les présentes que Joseph-Henri-Maurice-Pierre Parent, expéditeur, domicilié au 2030 Everett dans la ville de Montréal, district de Montréal a l'intention de présenter une demande au ministre de la justice de la province de Québec, en vue d'obtenir un décret du lieutenant-gouverneur en conseil changeant son nom de Joseph-Henri-Maurice-Pierre Parent en celui de Joseph-Henri-Maurice-Pierre Romanini.Daté à Montréal le 10 décembre 1973.Les procureurs du requérant, Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter, 55222-51-2-0 Taviss, Shayne & Levitt.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Paroisse de Saint-Augustin Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Augustin, municipalité de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, division d'enregistrement de Portneuf.Avis est par la présente donné que la partie restante des lots 433-8 et 434-14 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 novembre 1973.Pour le sous-ministre, 55220-o Benoît Grimard, a.-c.Paroisse de Sainte-Rose Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Rose, municipalité de la ville de Laval, division d'enregistrement de Laval.Avis est par la présente donné que le lot 491 est ajouté et qu'une partie des lots 71, 73, 74, 75, 76, 76-101, 76-102 et 77 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 7 novembre 1973.Pour le sous-ministre, 55220-o BenoIt Grimard, a.-g.Canton de Stanbridge Cadastre officiel du canton de Stanbridge, municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Slanbridge, division d'enregistrement de Missisquoi.Avis est par la présente donné que les lots 3184 à 3192 sont ajoutés et que les lots 865-1, 865-2, 866, 867, 865 et une partie des lots 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 et 875 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 6 novembre 1973.Pour le sous-ministre, 55220-o Benoît Grimard, a.-g.Joseph Henri Maurice Pierre Parent Notice is hereby given that Joseph-Henri-Maurice-Pierre Parent, Assistant Shipper, of the City and District of Montreal, and therein residing at 2030 Everett, will present a petition to the Minister of Justice of the Province of Québec for a decree of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Joseph-Henri-Maurice-Pierre Parent to Joseph-Henri-Maurice-Pierre Romanini.Dated at Montreal this 10th day of December, 1973.Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter, Taviss, Shayne & Levitt, 55222-51-2-0 Attorneys for Petitioner.Department of Lands and Forests Cadastre Parish of Saint-Augustin Official cadastre of the parish of Saint-Augustin, municipality of the parish of Saint-Augustin-de-Desmaures, registration division of Portneuf.Notice is hereby given that the remaining part of lots 433-8 and 434-14 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, November 15, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 55220-o For the Deputy Minister.Parish of Sainte-Rose Official cadastre of the parish of Sainte-Rose, municipality of the town of Laval, registration division of Laval.Notice is hereby given that lot 491 is added and that a part of lots 71, 73, 74, 75, 76, 76-101.76-102 and 77 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, November 7, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 55220-o For the Deputy Minister.Township of Stanbridge Official cadastre of the township of Stanbridge, municipality of the parish of Notre-Dame-de-Stanbridge, registration division of Missisquoi.Notice is herebv given that lots 3184 to 3192 are added and that lots 865-1, 865-2, 866, 867, 865 and a part of lots 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 and 875 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, November 6, 1973.Benoît Grimard, a.-g., 55220-o For the Deputy Minister. 7552 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 Commission des transports Québec Transport du Québec Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.FI \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulations 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (a.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.Avis de décisions rendues : V \u2014 Notice of decisions rendered : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu >¦.a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de mat ières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n\" 51 7553 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014¦ Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down iii section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.R61e Q-474 23540-V-D-l RICHER BOUTET, 180, 52c Rue ouest, Charlesbourg, Québec.Réle Q-475 23641-V-D-l CUY LEPAGE, 6238, Place des Lys, Orsain ville, Québec.Rule Q-476 23642- V-D-l JEAN ROCH MORIN, 7929, de Cornouaillo, Charlesbourg, Québec.R6lo Q-477 AUTOBUS LA MALBAIE ENR\u201e (J.Ph.Dufour) 48, rue Nairn, La Malbale.CM Charlevoix, P.Q.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local - contrat- Charlesbourg et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 6 milles des limites dudit endroit, pour le transport de mets préparés pour le compte du Restaurant Jardin du Bonheur.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local - contrat- Charlesbourg et tous les endroits situé» sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit, pour le trans|>ort tie mets préparés pour le compte du Restaurant Jardin du Bonheur.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - servico local - contrat - Charlesbourg et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant paa 6 milles des limite» dudit endroit, pour le transport de met» préparé» pour le compte du Restaurant Jardin du Bonheur.Demande d'augmentation de tarif pour le transport de personnes handicapées mentalement, de leur lieu de résidence situé a Pointe-au-Plo, La Mnlbnle, Cap-a-l Aigle, 8t-Fidéle, Clermont.St-Agnès, St-Almé-cles-Laoa, Notre-Dame-des-Monts pour se rendre a leur atelier de travail situé au Bud-ouest de la Rivière Malbaie et retour: Application for permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Charlesbourg and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said locality, for the transportation of prepared foods on behalf of Restaurant Jardin du Bonheur.Application for permit.The applicant requesta the following permit : Restricted trucking - local service - contract - Charlesbourg and all points located over n distance of not more than 5 miles from the limits of said locality, for the transportation of prepared foods on behalf ol Reataurant Jardin du Bonheur.Application for |»rmit.The applicant requesta the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Charlesbourg and all point» located over a distance of not more than 5 miles from the limita of said locality, for the transportation of prepared foods on behalf of Restaurant Jardin du Bonheur.Application for Increase in tariff for the transportation of mentally-handicapped persons, from their homes located in l'ojnte-au-Pic, La Malbaie, Cap-M'Aigle, St.Fidèle, Clermont, 8te.Agnèa, 8t, Aimé-des-Lae», Notre-Danie-des-Monts, to the workshop where they are employed, located to the southwest of Rlvière-Mulbaie, and return.Taux propoa* 637.00 par Jour Taux actuel 132.00 par jour Proposed rate $37.00 per day Current rate 132.00 per day 7554 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22.1973, Vol.105, No.51 Rôle Q-482 2552-A-D-2 (District-Judiciaire 41 Québec) YVON SAUCIER, 140, rue Comtois, Louiseville, Cté Maskinongé, P.Q.Chartier, Menard et Gourdeau Procureu rs/ A11 or neys Rôle Q-483 609-DY D-l AUTOS A LOUER RIMOUSKI INC.00.rue d'Auteuil, Rimouski.P.Q.Rôle Q-484 22753-V-D-l ANGELO FILION, 1050.rue St-Jean Baptiste, Québec (Les Saulesi, Cté de Québec.Tireur Haulaway ./operator BRAZEAU TRANSPORT INC.380.rue Burke, Rouyn, Cté de Témiscarningue, Tiré/Carrier Requérants conjoints/Joint applicants.Rôle Q-485 147-V-D-5 GOSSELIN TRANSPORT LTEE, 141.boul.George Smith.CP.456.Thetford Mines, Cté de Mégantic.Rôle Q-486 23413-V-D-2 CHARLES-EUGENE GUAY, 51, Carré Valois, Québec (Neufchatel), Cté de Québec G2A 1T6 Tireur Haulaway,/operator BRAZEAU TRANSPORT INC.380, rue Burke, Rouyn, Cté de Témiscarningue.Tiré/Carrier Requérants conjoints.Joint applicants.Droit additionnel.Classe de permis: Autobus.Service: Voyages h charte-partie (Ordonnance générale No 17): des municipalités de ta ville et de la paroisse de Louiseville à tout endroit situé dans un rayon de 100 milles et retour.Droit additionnel.La panie requérante qui est autorisée à donner les services de location de véhicules de promenade comme suit : Service: Location à court terme(moins d'une année) de véhicules de promenade à: \u2014 90.rue d'Auteuil.Rimouski; \u2014 Aéroport de Mont-Joli; \u2014 Hôtel Beaurivage.1ère Avenue, Ste- Anne-des-Monts; \u2014 Hôtel Copper Mountain, 700.5ème Rue.Murdochville; \u2014 Station Irving.Gaspé Harbour, demande à la Commission des transports du Québec le droit additionnel de donner les services de location de véhicules de promenade à court terme à: \u2014 Aéroport de la Ville de Gaspé.Service additionnel: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Angelo Filion h tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques et fardiers de Brazeau Transport Inc., (6793-V).selon les clauses c à z, au a zz, aaa à ///.ainsi que selon les clauses temporaires et expérimentales qqq, hhh et tu accordées le 14 février 1973.dudit permis No 6793-V.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis l'autorisation suivante: Droit additionnel: La détentrice est autorisée à louer, à long terme (60 mois), de LA.C.Limitée, permis 508-DYV, un (1) camion-tracteur dont la description apparaît au contrat de location déposé à la Commission.Freightliner 1974 (WFT6364) Série HV- 7KV.M,.Nouvelle demande: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Charles-Eugène Guay à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques et fardiers de Brazeau Transport Inc., (6793-V), selon les clauses c à z, aa à zz, aaa à ///, ainsi que selon les clauses temporaires et expérimentales 0U0.hhh et tu accordées le 14 février 1973.dudit permis No G793-V.Additional right.Class of permit: Bus.Service: Charter trips (General Order number 17): from the municipalities of the Town and of the Pariah of Louiseville to any point located within a radius of 100 miles and return.Additional right.The applicant, which is authorized to provide the following pleasure vehicle-leasing service: Service : Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than one year), at: \u2014 90 d'Auteuil Street, Rimouski; \u2014 Mont-Joli Airport; \u2014 Beaurivage Hotel.1st Avenue, Ste.A nne-des-Monts ; \u2014 Copper Mountain Hotel, 700 - 6th Street.Murdochville; \u2014 Irving Station, Gaspé Harbour, requests from the Québec Transport Commission the additional right to provide pleasure vehicle-leasing services on a short term basis at: \u2014 City of Gaspé Airport.Additional service: Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Angelo Filion to haul, with his duly-registered tractors, trailers and floats belonging to Brazeau Transport Inc.(6793-V), according to clauses r to z.aa to zz, aaa to///, as well as according to temporary and experimental clauses gov.hhh and nï granted on February 14.1973.of said permit No.6793-V.Modification of permit (additional right).The applicant requests the Commission to add to its permit the following authorization: Additional right: The permit-holder is authorized to lease, on a long-term basis (60 months), to I.A.C.Limitée, permit 50S-DYV, one (1) tractor-truck, which is described in the lease filed with the Commission.1974 Freightliner (WFT6364) Serial HV-78896.New request: Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Charles-Eugène Guay to haul, with his duly registered tractors, the trailers and floats of Brazeau Transport Inc., (6793-V), pursuant to clauses r.to z, aa to zz, aaa to ///, und pursuant to temporary and experimental clauses OQil' hhh and Hi granted on February 14, 1973, of said permit No.6793-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7555 Rôle Q-487 1697-A-D-l BEAUCE AUTOBUS INC., Beauceville, CP.370.Cté Beauce, P.Q.Rôle Q-488 19716-V-D-l TF PAUL-EMILE BELLAYANCE, 164.St-Denis.Black Lake.Cté Mégmntic.P.Q.Rôle Q-489 IRENEE GILBERT, 79, Notre-Dame.Robertson ville.( 'té Mégantic.14965-V-D-l Modification de permis de façon a ce qu'il soit ajouté les classes suivantes: Classe de permis: Autobus.Service : a) Transport d'écoliers de leur résidence de Beauceville Est, Ouest etSt-François Est.Ouest aux écoles de Beauceville Est, Ouest et retour.6) Transport d'écoliers de leur résidence de St-Sîmon des Mines aux écoles de Beauceville Est.Ouest et retour.c) Transport d'écoliers de leur résidence de St-Alfred aux écoles de Beauceville Est.Ouest et retour.d) Transport d'écoliers résidant dans Beauceville Est, Ouest et St-François Est.Ouest et tous ceux qui transfèrent (aux écoles) à Beauceville Est, Ouest et fréquentant les écoles de St-Georges et St-Joseph et retour.e) Transport d'écoliers de Beauceville Est.Ouest et St-François Est.Ouest, le midi des écoles de Beauceville h leur résidence située dans Beauceville Est, Ouest et St-François Est.Ouest et retour.Note.\u2014 Aucun droit au privilège de l'Ordonnance No 17 à l'exception des clauses sus dîtes.Demande d'augmentation comme suit: Ancien taux: local: Chauffeur, fourgon, camion £8.00 l'heure Aide additionnel Longue distance: Mille parcouru Emballage et déballage Chargement et déchargement Aide additionnel Taux proposés: local: Chauffeur, fourgon, camion Aide additionnel Longue distance: Mille parcouru Emballage et déballage Chargement et déchargement Aide additionnel 3.50 l'heure 0.60 3.10 du 100 lbs.8.00 l'heure 3.50 l'heure 9.50 l'heure 4.25 l'heure 0.70 4.10 du 100 lbs.9.50 l'heure 4.25 l'heure Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis les services suivante: 1) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - 1) De Roi-ert son ville à Sherbrooke, pour le transport des produits de l'érable, et retour avec barils vides, pour le compte de Beaudry Maple Products Inc.2) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - 2) De Robertson ville à Granby.pour le transport des produits de l'érable, et retour avec barils vides, pour le compte de United Maple Products Limited; 3) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - 3) De Robertsonville à Touraine.pour le transport des produits de l'érable, et retour avec barils vides, pour le compte de Jean-Marie Vachon.Modification of permit in order to add the following clauses: Class of permit: Bus.Service : (a) Transportation of school children from their homes in Beauceville East, West and St.François East, West, to the schools in Beauceville East, West and return.(6) Transportation of school children from their homes in St.Simon-des-Mines to the schools in Beauceville East, West and return.(c) Transportation of school children from their homes in St.Alfred to the schools in Beauceville East, West and return.(-/) Transportation of school children residing in Beauceville East, West and St.François Eaet.West and all those who transfer (to the schools) at Beauceville East, West and who attend the schools in St.Georges and St.Joseph and return.(«) Transportation of school children from Beauceville East, West and St.Francois East.West, at noon time, from the schools in Beauceville to their homes in Beauceville East, West and St.François East.West and return.Note.\u2014 Applicant not entitled to the privilege granted by Order No.17 with the exception of the above-mentioned clauses.Request for increase as follows: Former rate: Local: Driver, van, truck Assistant Long distance: Mile covered Packing and unpacking Loading and unloading Assistant Proposed rates: Local: Driver, van, truck Assistant Long distance: Mile covered Packing and unpacking Loading and unloading Assistant *8.00 / hour 3.50 / hour 0.60 3.10 per 100 lbs.8.00 / hour 3.50 / hour 9.50/hour 4.25 / hour 0.70 4.10 per 100 lbs.9.50 / hour 4.25 / hour Modification of permit: The applicant requests that the following services be added to his permit: (1) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (1) From Robertsonville to Sherbrooke, for the transportation of maple products and return with empty barrels, on behalf of Beaudry Maple Products Inc.(2) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (2) From Robertsonville to Granby, for the transportation of maple products, and return with empty barrels, on behalf of United Maple Products Limited; (3) Restricted trucking - long distance '-restricted route - contract.(3) From Robertsonville to Touraine.for the transportation of maple products, and return with empty barrels, on bshalf of Jean-Marie Vachon. 7556 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December 22, 1973, Vol.105, So.51 Rôle Q-490 16903-V-D-2 CARTIER TRANSPORT INC., 302.rue Otis, Sept-Ilcs.Cté Saguenay.Rôle Q-491 3031-A-D-l AUTOBUS GERARD JUNEAU INC., 1681.rue Lottinville.St-Paulin.Co.Maskinongé, P.Q.Rôle Q-492 0633-V-C-l BOUCHARD TRANSPORT ENRC., (Léger Bouchard).Rang Hl-Antoine Sud, R.R.3, Bate St-Paul, Cté de Charte voix-Ouest, Partie-requérante / Applicant.JEAN BOUCHARD, f207) St-FraneoIs-Xavier-de- la-Petlte-Rivlère.Cté de Charlevoix-Ouest, Partie-intimée / Respondent.Modification de la clause g.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec que soit enlevée la restriction appaniissant à la clause g de son permis laquelle se lit comme suit: 0) Transport général - longie distance -route restreinte \u2014 17) Des différents sites d'aménagement des Rivières Manicouagan et Outardes a Hauterive.Baie Comeau.Québec.Trois-Rivières, Shawinigan et Montréal et retour.Restriction : La clause o ci-dessus est temporaire et expirera le 31 mars 1973, ou a une date antérieure si les travaux sont terminés plus tôt; la date pourra être retardée et le permis prolongé sur demande motivée de la part de la requérante.Renouvellement de permis.Classe de permis: Autobus.Service : Le requérant demande de renouveller en permanence le service No 3, dûment autorisé savoir: Transport d'étudiants résidant dans les villages et paroisses de St-Paulin et Charctte et se rendant au CEGEP de Trois-Rivières et au Pensionnat Notre-Dame (Ecole Normale) situé au Cap-de-la-Madeleine, et retour.Note: a) Aucun changement au tarif en vigueur.6) Aux mêmes conditions et restrictions sauf le paragraphe 3 qui se lit: Ce permis est valide jusqu'au 31 août 1973 et renouvelable a cette date sur demande écrite de la détentrice.Convocation.Demande de vérification des services de transport fournis par; Jean Bouchard, (207) 8t-Erençoi3-Xavier-de-l a-Petite-Rivière, Cté de Charlevoix-Ouest.No 9633-V.u la demande de la partie requérante.Amendment to clause g.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to remove the restriction appearing in clause g of its permit which reads as follows: (g) General trucking - long distance - restricted route - (g) From the various development sites on the Manicouagan and Outardes rivers at Hauterive.Baie Comeau.Québec, Trois-Rivières, Shawinigan and Montreal and return.Restriction : The above mentioned clause g is temporary and shall expire on March 31, 1973.or at a previous date if the work is completed earlier; the date may be delayed and the permit extended upon motivated request from the applicant.Renewal of permit.Class of permit: Bus.Service : The applicant requests a permanent renewal of service No.3.duly authorized, namely: Transportation of students residing in the Villages and Parishes of St.Paulin and Charette and attending the CEGEP in Trois-Rivières and Notre-Dame Boarding School (Normal School) located in Cap-de-la-Madeleine, and return.Note: (A) No change in the tariff in force.(B) I'nder the same conditions and restrictions with the exception of paragraph 3 which reads as follows: this permit is valid until August 31.1973 and renewable from that date upon written request of the holder.Convocation.Application for checking the transportation services provided by: Jean Bouchard, No.9633-V (207) St-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière, County of Charlevoix-West.at the request of the applicant.Rôle Q-403 10832-V-D-l 21093-V-D-2 HERVE BELANGER, Bt-Damase-de-L'I*let, Cté de L'IsIet et L.BILODEAU & FILS LTEE, Hnnffeur, Cté de Bellechasse, ('esxlun de la propriété du système de transport (vente), Hervé Bélanger demande l'autorisation de céder a la compagnie: L.Bilodeau & Fils Ltée, Honfleur, Cté de Bellechaase, la propriété du système de transport suivant: Permis No 16832-V: Transport restreint - longue distance -route restreinte - Irrégulier - Transfer of the ownership of a transportation service (sale) Hervé Bélanger requests authorization to transfer to: L.Bilodeau & Fils Ltée, Honfleur, County of Bellechasse.the ownership of the following transportation service: Permit No.16832-V: Restricted trucking - long distance - restricted route - irregular - From St.Damase and all points located within a radius of 25 miles from said point to Québec, St.Anselme, Victoriaville, St.Hyacinthe and Joliette for the transportation of live fowl (turkeys and chickens in cages), on behalf of the fowl-breeders in general and return with empty cages; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7557 Rôle Q-494 5311-V-D-I V.BOUTIN EXPRESS INC., 1397, rue Savoie.CP.400.Plessisville.Cté de Mégantic.Rôle Q-495 1068-DYV D-l LOCATION FRONTENAC INC., 6522.Crémazie.Lac Mégantic.Cté de Frontenac.P.Q.Rôle Q-496 23526-V-D-l MESSAGERIE MANICOUAGAN ENR., (Serge Tremblav).14GÀ, Morel, Hauterive.Cté de Saguenay, G5C 2S2 Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De St-Damase et de tous les endroits situés dans un rayon de 100 milles dudit endroit ï St-Anselme, pour le transport d'oiseaux vivants (dindes, volailles en cages) et retour avec cages vides, pour le compte de la Coopérative de Dorchester.Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - A St-Anselme.de tous les endroits situés dans un rayon de 200 milles dudit endroit, pour le transport d'oiseaux vivants (dindes, volailles en cages), et retour avec cages vides, pour le compte de la Coopérative de Dorchester.Modification de permis (droit additionnel).La partie requérante demande d'ajouter à son permis le droit additionnel suivant: Droit additionnel: En donnant les services autorisés par les clauses de son permis, la détentrice a le droit de louer ses tracteurs, h court terme, aux clients nommés ci-après, aux fins de tirer leurs remorques immobilisées par une panne ou bris de moteur de leur propre tracteur, et ce, conformément aux dispositions des articles 13-A et suivants de l'Ordonnance générale sur le Camionnage: Arco Construction Inc.R.R.49, Plessis-ville.Rapid Pac Inc., 1811», Bte-Anne, Plessisville.Lionel Henri Enrg., 1448.St-Kdouard.Plessisville.Belle Ne & Goulet Inc.ISOO ave.Rousseau, Plewis ville.André Pelchat.182.Dubé.Plessis^ille.Les Producteurs de Sucre d'Erable du Québec.2100 ave.St-Laurent.Plessisville.Lionel Jam Inc.R.R.19.Plessisville.Armand Bolduc.1868 ave.Bélanger.Plessisville.Philippe Lamothe Inc.1057.Principale.St-Ferdinand-de-Mé-gantic.Nouvelle demande.La partie requérante demande a la Commission des transports du Quel ec de l'autoriser a donner les services de location de véhicules comme suit : Service : Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de cominerre et de livraison au sens du code de la route, à \u2022\u2022522.Crémazie.Lac M?gantic.Demande de permis.La partie repuérante demande le permis suivant : Transport restreint- service local-contrat - Hauterive et tous les endroits situés sur UIU distance ne dépassant pns 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de commandes d'épicerie et le transport de meubles, le tout pour le compte de Hudson's Bav Co.Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Hauterive à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville/pour la livraison de commandes d'épicerie et le transport de meubles, le tout pour le compte de Hudson's Bay Co.Transport restreint - servie» local - Hauterive et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de commandes de produits pharmaceutiques.Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From St.Damase and all points located within a radius of 100 miles from said point to St.Anselme, for the transportation of live fowl (turkeys and chickens in cages) and return with empty cages, on behalf of Coo|>é-rative de Dorchester; Restrcted trucking - long distance - radius - contract - To St.Anselme, from all points located within a radius of 200 miles from said point, for the transportation of live fowl (turkeys and chickens in cages), and return with empty cages, on behalf of Coopérative de Dorchester.Modification of permit (additional right).The applicant requests that the following additional right be added to its permit; Additional right: When providing the services authorised by the clauses of its permit, the holder shu II ha ve the right to lease its tractors, on a short-term basis, to the customers hereinafter nuined, for the purposes of hauling their trailers immobilized by a breakdown or engine trouble in their own tractors, the foregiong in con-formitv with the provisions of articles 13-A and following of the General Order on Ti uck-ing: Arco Construction Inc., R.R.49, Plessisville.Rapid Par Inc.1819 Ste.Anno, Plessisville.Lionel Henri Enrg., 1448 Si.Edouard, Plessisville.Belle Isle £ C .lot Inc., 1800 Rousseau Avenue.Plessi*.lie.André Pelchat.182 Dubé.Ple^isviHc Lc, Producteurs d I Sucre d'Erable du Quebec.2100 St.Laurent Avenue.Plessisvill.-.Lionel Jam Inc.R.R.49.Plessisville Armand Bolduc.1868 Bélanger Awivie.PIcmUviUc.Philippe Lamothe Inc., 1057 Principale, St Ferdinand-de- Mégantic.New application.The applicant requests from the QuébRïï transport Commission the authorization to provide the following vehicle-leasing services: Service: Leasing, on a short-term basis Oess than one year),of commercial and delivery vehicles within the meaning of the Highway Code.a.6522 Crémazie, Lac Mégantic Application for a permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service con tract - Hauterive and all points located over a distance of not more than 5 mile:, from the limits of said Town, for the delivery of grocery ordci - and the transportation of furniture, the whole on behalf of Hudson's B.iy Co.Restricted trucking-long distance-iaù.js-contract - From Hauterive to all points located within a radius of 30 miles from the limita of said Town, for the delivry of grocery orders and the transportation of furniture, the whole on behalf of Hudson's Bay Co.Restricted trucking - local service -Hauterive and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said Town, for the del* ery of phur maceuticul orders. 7558 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol 105, No.51 Rôle Q-497 32-V-D-3 TRANSPORT DALLA I RE LTEE, 90 ouest, boul.Taché.O.P.218.Montmagny.Cté Montmagny.Rôle Q-498 23556-V-D-l RICHARD ROY.2215.boul.Henri Bourassa.Québec 3.Cté de Québec.Rôle Q-499 23555-V-D-l EMILE NOEL, 172.De la Sultane.Québec (Neufchatelj.Cté de Québec.Rôle Q-500 23553-V-D-l ARMAND BILODEAU, 99, rue St-Charles.Québec (Neufchatel).Cté de Québec.Modification de la clause c: La détentrice du permis 32-V, dont la clause c se lit comme suit: c) Transport général - longue distance -route - c) De St-Raphaël.St-Né.-ée et Montmagny :\\ Levis.Québec, Trois-Rivières et Montréal pnr les routes Nos 9, 2, 5 et 20.et retour.En donnant le service autorisé par la clause r, la détentrice est autorisée À donner le service de toutes les localités situées dans le district électoral-provincial de Montmagny.Droit additionnel re: clause c: En effectuant le service autorisé par la clause c de son permis, la détentrice est autorisée à se servir de camions isothermes.La partie requérante demande à ce que cettedite clause c soit modifiée pour se lire, à l'avenir, comme suit: c Transport général -longue dislance- route- c) De St-Raphaël,St-Nérée.Notre-Dame-Auxiliatrice-dc-Bucklard et Montmagny à Levis.Québec.Trou-Rivières et Montréal par les routes Nos 9, 2, 5 et 20.et retour.La requérante, par la présente renonce à son droit de cueillette et de livraison que lui confère l'Article 47, paragraphe 8.de l'Ordonnance générale sur le camionnage, en ce qui a trait au seul point d'origine, Notre-Dame-Auxiliaire-de-Buckland.En donnant le service autorisé par la clause c, la détentrice est autorisée h donner le service de toutes les localités situées dans les districts électoraux-provinciaux de Montmagny et L'Islet.Droit additionnel re: clause c:.En effectuant le service autorisé par la clause r de son permis, la détentrice est autorisée à se servir de camions isothermes.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint-service local-contrat- Quéhec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison à domicile de mets préparés, pour le compte de Cadri.Royaume de la Pizza Inc.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint-service local-contrat-Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison à domicile de mets préparés, pour le compte de Cadri.Royaume de la Pizza Inc.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local - contrat - Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison u domicile de mets préparés, pour le compte de Cadri.Royaume de la Pizza Inc.Modification of clause c: The holder of permit 32-V, in which clause c reads as follows: (c) General trucking-long distance-route - (c) From St.Raphaël.St.Nérée and Montmagny to Levis, Québec.Trois-Rivières and Montreal via Highways Nos.9.2.5 and 20, and return.When providing the service authorized by clause c, the holder is authorized to provide service in all localities situated in the provincial electoral District of Montmagny.Additional right re: clause c: When operating the service authorized by clause c of its permit, the holder is authorized to use temperature-controlled trucks.The applicant requests that said clause c be modified to read henceforth as follows: (c) General trucking-long distance-route -(c) From St.Raphael, St.Nérée.Notre-Da-me-Auxiliatrice-de-Buckland and Montmagny to Levis.Québec, Trois-Rivières and Montreal via Highways 9.2, 5 and 20, and return.The applicant hereby waives its right to pick up and deliver, granted by article 47.paragraph 8 of the General Order on Trucking, as regards only to the point of origin, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.When providing the service authorized by clause c.the holder is authorized to provide service from all points located in the provincial electoral Districts of Montmagnv and 1'Islet.Additional right re: clause c: When operating the service authorized by clause c of its permit, the holder is authorized to use temperature-controlled trucks.Application for a permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Québec and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City, for the home delivery of prepared foods, on behalf of Cadri, Royaume de la Pizza Inc.Application for a permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Québec and all points located over a distance ofnot more than 5 miles from the limits of said City, for the home delivery of prepared foods, on behalf of Cadri, Royaume de la Pizza Inc.Application for a permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Québec and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City, for the home delivery of prepared foods on behalf of Cadri, Royaume de la Pizza Inc. OMETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, ,i° 51 7559 Rôle Q-501 23554-V-D-l CHARLES-EDOUARD BEAUMONT, 485, Senterre.Vanier, CU de Québec Rôle Q-502 23561-V-D-l RAYMOND A.GAUDET, O.P.33, Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine.Procureur / Attorney : Me Fernand Devenu.Rôle Q-503 20174-V D-l TF CHAPPLE L.H.LTD.220.est Grande-Allée.Suite 1000.O.P.609, H.V.Québec 4.P.Q.Siège social: ¦ Head ofl.ee Lincoln Road, P.O.Box 1505, Fredericton, N.B.Rôle Q-504 1034-DYV D-l EASTERN RENTALS LIMITED, 2.Place Québec.Suite 202.Québec.P.Q.Siège social 7 Head office 130.Adam St.P.O.Box 421, Belleville.Ontario.Rôle Q-505 4545-V-D-l TRANSPORT LAVOIE LTEE, 059 - 118e Rue, Montmorency.Cté de Québec.Rôle Q-507 23558-V-D-l RENE DUBOIS.CP.568.Matagami.Cté d'Abitibi tireur BRAZEAU TRANSPORT INC., (6793- Vi 380, rue Burke.Rouyn, Cté de TémiscHiningue tiré.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant; Transport restreint - service local - contrat - Québec et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison a domicile de mets préparés, pour le compte de Cadri, Royaume de la Pizza Inc.Nouvelle demande.La partie requérante demande le permis suivant: Transport général - longue distance - territoire - De tous les points à tous les points situés sur les Iles-de-la-Madeleine incluant tous les ports et aéroports, pour le transport de marchandises pour le public en général.Droit additionnel: En donnant le service précité, le requérant aura le droit d'utiliser des véhicules réfrigérés.La requérante demande i\\ la Commission des transports une modification de tarifs pour le transport de maisons mobiles.Elle publie son nouveau tarif No 7 pour remplacer le No 6.Nouvelle demande.La requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à louer des véhicules comme suit: Service: Location à long terme (une année ou plus) de véhicules de commerce et de livraison (tracteurs et remorques) seulement ù: \u2014 Union Carbide of Car.ada Ltd.\u2014 General Wire and Cable Company Ltd.\u2014 Mead Johnson Canada, une filiale de Bristol Myers Canada Ltd.\u2014 Fabricon Manufacturing Limited.Demande de prolongation de délai.La partie requérante, qui détient un permis dont les restrictions se rapportant aux clauses h et t se lisent: La clause h de ce parmi* est sujette à la production d'un permis complémentaire de l'Ontario Highwav Transport Board, avant le 31 décembre 1973.La clause t de ce permis est sujette à la production d'un permis complémentaire de I Interstate Commerce Commission, avant le 31 décembre 1973.Demande une prolongation du délai (1 an) pour lui permettre de produire dans l'intervalle les |>ermis complémentaires requis.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'auto-iser René Dubois à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques et fardiers de Brazeau transport Inc.(6793-V).selon les clauses c ù r.aa à st.aaa à ///, ainsi que >elon les clauses temporaires et expérimentales gag, hhh et ni accordées le 11 février 1973.dudit permis 6793-V.Application for permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service - contract - Québec and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said City, for home delivery of prepared meals, on behalf of Cadri, Royaume de la Pizza Inc.New application.The applicant requests the following permit: General trucking-long distance-territory - From any point to any other point located in the Magdalen Islands, including all ports and airports, for the transportation of goods for the public at large.Additional right: In providing the aforesaid service, the applicant is authorized to utilize temperature-controlled vehicles The applicant requests the Transport Commission to modify its tariffs for the transportation of mobile homes and publishes its new tariff No.7 in replacement of tariff No.6.New request.The applicant is asking the Québec Transport Commission authorization to lease vehicles as follows: Sen-ice: Leasing of commercial and delivery vehicles (tractors and trailers) on a long term basis (one year of more) exlcusively to: Union Carbide of Canada Ltd.General Wire and Cable Company Ltd.Mead Johnson Canada, a division of Bristol Myers Canada Ltd.Fabricon Manufacturing Limited-Application for extension of time limit.The applicant which holds a permit ir which the restrictions concerning clauses / and t read as follows: Clause h of this permit is subject to th< production of a complementary permit to b-issued by the Ontario Highway Transpor Board before December 31, 1973.Clause t of this permit is subject to th production of a complementary permit to b issued by the Interstate Commerce Commù pion before December 31.1973.Requests an extension of the time lim.(one year) to enable it to produce, in th meantime, the required complementary pel mlta.New application.Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize René Dubo to haul with his duly-registered tractors, tl trailers and floats of carrier Brazeau Tran port Inc.(6793-V) according to clause c ¦ z.aa to zz.aaa to ///.of said permit N 6793-V, and also according to tempora ¦ad experimental clauses gag, hhh and i granted on February 14.1973. 7560 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973.Vol.105, No.51 Rôle Q-509 802-DYV & 22-DYS-D-l AUTO NEIGE MAURICIE ENRG., (Gérard.François et Fernand Hamel, opérant sons le nom de:).5702, boulevard des Hêtres.Shawînigan, P.Q., Requérants-vendeurs /Applicant vendors et {and CARAVANE MAURICIE INC., requérante-acquéreur.i Applicant purchaser Rôle Q-513 15251-V-D-5 PHILIPPE RICHARD LTEE, St-Pascal, \u2022 *té Kamouraska.Rôle Q-514 15251-V-D-6 PHILIPPE RICHARD, LTEE, St-Pascal, Cté Kamouraska.Demande de transfert de permis et vente de services.Les requérants vendeurs qui sont détenteurs de permis de location de véhicules demandent h la Commission des transports du Québec d'autoriser le transfert de leur permis et la vente de leur service de location à la Compagnie requérante acquéreur Caravane Mauricie Inc.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Québec à tous les endroits situés dans les districts électoraux-provinciaux de Montmorency, Charlevoix, Saguermy et Duplessis, (produits alimentaires pour les animaux), avec véhicule dompeur muni d'un souffleur, pour le compte de Moulées Miracles (Div.de Ogilvie Flour Mills Co.Ltd.' et Maple Leaf Mills Limited.À l'occasion de ces voyages, la détentrice est autorisée au transport de moulées médi-camentées en sacs dont le jmids n'excédera pas 2,000 lbs par voyage.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance -rayon - contract - De Québec a tous les endroits situés dans les districts électoraux-provinciaux de Chi-coutimi, Dubuc, Jonquicre, Lac St-Je:m et Uoberval, pour le transport de moulées en vrac (produits alimentaires pour les animaux), avec véhicule dompeur muni d'un souffleur, pour le compte de Moulées Miracle (Div.de Ogilvie Flour Mills Co.Ltd.).Maple Leaf Mills Ltd.et Moulées Super-sweet Feeds (Div.Robin Hood Multifoods Limited).A l'occasion de ces voyanes.la détentrice est autorisée au transport de moulées médi-camentées en sacs dont le poids n'excédera pas 2.000 lbs par voyage.Application for transfer of permit and sale of services.The applicant vendors, which hold a vehicle-leasing permit, request the Québec Transport Commission to authorize them to transfer their permit and sell their leasing services to the applicant purchaser, Caravane Mauricie Inc.Modification of permit.The applicant requests that the following service be added to its permit: Restricted trucking-long distance-radius-contract - From Québec City to any point located in the Provincial Electoral Districts of Montmorency.Charlevoix, Saguenay and Duplessis.for the transportation of feed (meal) (foodstuffs for livestock in bulk), by dump truck equipped with a blower, on behalf of Moulées Miracles (Div.of Ogilvie Flour Mills Co.Ltd.) and Maple Leaf Mills Limited.In providing this service, the permit-holder is authorized to transport medicated feed-in bags, provided the total load does not exceed 2.000 lb.per trip.Modification of j>ermit.The applicant requests that the following service be added to its permit: Restricted trucking-long distance-radius-contract \u2014 From Québec to any point located in the Provincial Electoral Districts of Chicoutimi.Dubuc.Jonquicre.Lake St.John and Rober-val.for the transportation of feed (meal) (foodstuffs for livestock in bulk), by dump truck equipped with a blower, on behalf of Moulées Miracle (Div.of Ogilvie Flour Mills Co.Ltd.).Maple Leaf Mills Ltd.and Moulées Supersweet Feeds (Div.of Robin Hood Multifoods Limited?.In providing this service, the permit-holder is authorized to transport medicated feed in bags, provided the total load does not exceed 2.000 lb.per trip.55212-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105- année, n° 51 7561 V \u2014 Avis des décisions rendues : La Commission donne avis de la nalurc des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IX CHAMBERS \t\t\t\tG.O.O.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-572-TF\t12-12-73\tS123-V-D-1-TF JOHN N.BROCKLESBY\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT LTD.\t\t6246\t27-10-73\tM-380\tAccordée / Granted MCR-573-TF\t12-12-73\t1733-V-D-2-TF\t\t\t\t\t MCR-574-TF\t\tD.DONNELLY LIMITED\t\t6246\t27-10-73\tM-378\tAccordée / Granted \t12-12-73\t1930-V-D-5-TF PROVOST CARTAGE\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t6246\t27-10-73\tM-381\tAccordée / Granted MCR-575-TF\t12-12-73\tCANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU\t\t\t\t\t \t\tASS'N\t\t6420\t3-11-73\tM-4 20\tAccordée / Granted MCS-268-TF\t12-12-73\t909S-V-D-1-TF LA POINTE TRANS-\t\t\t\t\t \t\tPORT LTEE\t\t6425\t3-11-73\tM-425\tAccordée / Granted MSM-3-TF\t12-12-73\t32-N-D-l-TF CLARKE STEAMSHIP\t\t\t\t\t \t\tCO.LTD.\t\t6420\t3-11-73\tM-419\tAccordée / Granted 55212-0 Place d'affaires dans la Province Place of Business in the Province CHARLES DOUGLAS GL'RNEY Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie > CHARLES DOUGLAS GURXEY », est 2025 Chemin St-François, Dorval, P.Que.lœs procureurs de la compagnie.Paqiette, Paqlette.55225-0 Pkkkeaii.t & Ri vet.CHARLES DOUGLAS GURNEY Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"CHARLES DOL'CLAS GURNEY\" is 2025 St.Francois Road, Dorval, P.Que.55225-0 Paqlette.Paqiktte, Pkiiheai'lt & Rivet, Attorneys for the company.Charte \u2014 Charter \u2014 demandes d'abandon de Applications for Surrender of JOS.CAiM.VRDA INC.Prenez avis que la compagnie «.IOS.CAMARDA IXC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 55262-0 Me C.James Galileo.JOS.CAMARDA INC.Notice is given that \"JOS.CAMARDA INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me C.James Galileo, 55262 Attorney for the company. 7562 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 LES DIVERTISSEMENTS LIMARI INC.Prenez avis que la compagnie « LES DIVERTISSEMENTS LIMARI INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.L'adm in istrateur provisoire.2.rue Roger, Jean Cocbnoyeb.Ste-Pierre-de-Sorel, Que.55250-o LES DIVERTISSEMENTS LIMARI INC.Notice is given that \"LES DIVERTISSEMENTS LIMARI INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jean Cournover, 2 Roger Street, Acting Director.St.Pierre-de-Sorel, Québec.55250 ROBERT G.FORBES INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « ROBERT G.FORBES INC.», une compagnie incorporée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social dans la Cité de I.ennoxviile, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la I.oi des compagnies.Daté à Sherbrooke, ce 21e jour de novembre 1973.Les procureurs de la compagnie, 55251-o Lynch, MacLakex & Hackett.ROBERT G.FORBES INC.Notice is hereby given that \"ROBERT G.FORBES INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Lennoxville, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Sherbrooke, this 21st day of November 1973.Lynch, MacLaren & Hackett, 55251-0 Attorneys for the company.FLTURIAN LAMPS LIMITED Avis est par les présentes donné que i des compagnies, et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir l'abandon de sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 11 décembre 1973.Le président, 55252-0 Max Rvdib.FUTURIAN LAMPS LIMITED Notice is hereby given that \"FUTURIAN LAMPS LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this December 11, 1973.Max Rcdie, 55252-0 President.RONESS-SMITH FURS INC.Avis est donné que la compagnie « RONESS-SMITH FURS INC.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Ix>i des compagnies.Donné à Montréal, ce 7e jour de décembre 1973.Le secrétaire, 55253 .Iack Roness.FERME AVICOLE ST-ESPRIT CO.LTEE Prenez avis que la compagnie « FERME AVICOLE ST-ESPRIT CO.LTEE».dont le siège social est situé à St-EspriL Comté Momtcalm, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Joliette, le 11 décembre 1973.Le procureur de la compagnie.55269-0 Me Clément Thidel.RONESS-SMITH FURS INC.Notice is hereby given that \"RONESS-SMITH FURS INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 7th day of December 1973.Jack Roness, 55253-0 Secretary.FERME AVICOLE ST-ESPRIT CO.LTEE Take notice that \"LA FERME AVICOLE ST-ESPRIT CO.LTEE\", having its head office at St-EspriL district of Joliette, will apply to Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Joliette, 1 lnd of December 11, 1973.Me Clément Trcdel, 55269-0 Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE VU QUÉBEC.-22 décembre 1973, 105' année, \u201e° 51 7563 Divers Compagnies Miscellaneous Companies LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE La compagnie « LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Gilles Laforge.55230-o 2185-69 BELLAMY ET CIE LTEE Avis est donné que la compagnie « BELLAMY ET (TE LTEE a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le président, Israel Fixkielstein.55254 2422-67 BISCUITS MONTMAGNY INC.MONTMAGNY BISCUITS INC.La compagnie « BISCUITS MONTMAGNY INC.\u2014 MONTMAGNY BISCUITS INC.- donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 4.Le secrétaire.Ferxaxd Bovlet.55255-0 3977-44 LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE Notice is given that \"LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE\" has reduced the number of its directors from 5 to 3.Gilles Laforge,-Secretary.55230 2185-69 BELLAMY ET CIE LTEE Notice is given that \"BELLAMY ET CIE LTEE\" has changed the number of its directors from 4 to 3.55254-0 Israel Fixkielsteix, President.2422-67 BISCUITS MONTMAGNY INC.MONTMAGNY BISCUITS INC.Notice is given that \"BISCUITS MONTMAGNY INC.- MONTMAGNY BISCUITS INC.\" has reduced the number of its directors from 5 to 4.55255 Ferxand Boulet, Secretary.3977-44 CLUB DE TIR DE DRUMMONDVILLE INC.La compagnie « CLUB DE TIR DE DRUMMONDVILLE INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 7 à 3.Le secrétaire, Claude Beau lieu.55256-0 2823-71 CLUB DE TIR DE DRUMMONDVILLE INC.Notice is given that \"CLUB DE TIR DE DRUMMONDVILLE INC.\" has reduced the number of its directors from 7 to 3.Claude Beaulieu.Secretary.55256 2823-71 DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.La compagnie « DORAIS.LUSSIER CONSTRUCTION INC.» donne avis quelle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 3.Le président, Roger Dorais.55257-0 \"222-59 LES STUDIOS MARKO INC.MARKO STUDIOS INC.La compagnie « LES STUDIOS MARKO INC.-MARKO STUDIOS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 3 à 5.Le secrétaire.Jacques Duhamel.55259-0 13891-58 DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.\" has reduced the number of its directors from 4 to 3.Roger Dorais, President.55257-0 7222-59 LES STUDIOS MARKO INC.MARKO STUDIOS INC.Notice is given that \"LES STUDIOS MARKO INC.\u2014 MARKO STUDIOS INC.\" has increased the number of its directors from 3 to 5.Jacques Duhamel.Secretary.55259 13891-58 7564 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973.Vol.105, No.51 LEDUC & LEDUC LIMITEE La compagnie « LEDUC & LEDUC LIMITEE » 'tonne avis qu'elle a changé le nombre île ses administrateurs de 7 à 3.Le directeur général, Maurice Brault.55258-0 1054-21 Sièges sociaux LES BRASSERIES J.A.B.INC.J.A.B.PUBS INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « LES BRASSERIES J.A.B.INC.\u2014 J.A.B.PUBS INC.».constituée en corporation par lettres patentes émises en date du 16 octobre 1973.en vertu de la première partie de la Loi des compagnies a établi son siège social au 4489 ouest, rue Sherbrooke, Westmount, district de Montréal.A compter de la date des présentes, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social et sa principale place d'affaires.Donné à Westmount.ce 1er novembre 1973.(Sceau) Le secrétaire-trésorier.55231-o Roger Alary.738452 R.BLANCHETOT LTEE Avis est donné que la compagnie « R.BLANCHETOT LTEE » constituée en corporation par lettres patentes en vertu de la Loi des compagnies en date du 6 juin 1973.et ayant son siège social dans la ville de Saint-Jean, a établi son bureau au No 35 rue Saint-Jacques, à Saint-Jean.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Saint-Jean, ce 5e jour de décembre 1973.Le président.55232-0 Raymond Blanciietot.LEDUC & LEDUC LIMITEE Notice is given that \"LEDUC & LEDUC LIMITEE\" has reduced the number of its directors from 7 to 3.Maurice Brault, General Manager.55258 1054-21 Head offices LES BRASSERIES J.A.B.INC.J.A.B.PUBS INC.Notice is hereby given that \"LES BRASSERIES J.A.B.INC.\u2014 J.A.B.PUBS INC.\".a company incorporated by letters patent issued on October 16th.1973 under the provisions of Part I of the Companies Act, has established its head office on 4489 Sherbrooke Street West, Westmount, district of Montreal.From and after the date of present notice, the said office shall be considered by the company as being the head office and principal place of business of the company.Dated at Westmount.this November 1st, 1973.(Seal) Roger Alary.55231-0 Secretary treasurer.738452 R.BLANCHETOT LTEE Notice is hereby given that \"R.BLANCHETOT LTEE\" a company incorporated by letters patent under the Companies Act on June 6th, 1973.and having its head office in the City of Saint-Jean, has established its office at 35 Saint-Jacques Street, Saint-Jean.From and after the date of this notice, the said office shall be constituted by the company as being the head office of the company.Dated at Saint-Jean, this 5th day of December 1973.Raymond Blanchetot, 55232-0 President.CAFE CHEZ DESROCHERS INC.Avis est donné que ta compagnie « CAFE CHEZ DESROCHERS INC.» constituée en corporation en vertu de la loi des companies en date du 11 octobre 1973 et ayant son siège social à Windsor, a établi son bureau au 231 rue Main.Windsor.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Sherbrooke, ce 22e jour de novembre 1973.Le président.55233-o André Desrochers.CAFE CHEZ DESROCHERS INC.Notice is given that \"CAFE CHEZ DESROCHERS INC.\", incorporated under to the Companies Act on October 11.1973.and having its head office in Windsor, has established its office at 231 Main Street, Windsor.From the date of this notice, said office shall be considered by the Company as its head office.Given in Sherbrooke, this 22nd day of November, 1973.André Desrochers, 55233 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.JJ décembre 1973.105' année.n° 51 7565 LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE La compagnie « LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 612.rue St-Jacques ouest.Montréal, au numéro 700, boulevard I.aure, Sept-Ilcs.Le secrétaire.55230-o Gilles Laforge.2185-69 LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE Notice is given that \"LES ENTREPRISES CUNIAL LTEE\" has transferred its head office from 612 St.lames Street West, Montreal, to 700 Laurc Boulevard.Sept-Iles.Gilles Laforge.55230 Secretary.2185-69 CENTRE LANGELIER INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie \u2022 CENTRE LANGELIER INC.¦ constituée en cor-poration en vertu de la première partie de la Loi «les compagnies par lettres patentes en date du 25e jour de novembre 1968, a transféré son siège social au 5075.rue de Sorcl, en la ville de Montréal.Montréal, le 23 novembre 1973.Le secrétaire.Harry Glassmax.55234-e 5635-68 CENTRE LANGELIER INC.Notice is hereby given that \"CENTRE LANGELIER INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated the 25th day of Noveml>er, 19G8 has moved its head office to 5075 lie Sore] Street, in the City of Montreal.Montreal, November 23, 1973.Hahiiy Classman, Secretary.55234-0 5635-68 \\NDRE CLAUDE INC.La compagnie « ANDRE CLAUDE INC- » donne ft via qu'elle a changé son siège social du numéro 902, avenue Canora.Mont-Roval, au numéro 6820, rue St-Hubert, Montréal.La secrétaire.Raymondf.B.Poissant.55235-0 2253-6S ANDRE CLAUDE INC.Notice is given that \"ANDRE CLAUDE INC.\" has transferred its head office from 902 Canora Avenue.Mount Royal, to 6820 St.Hubert Street, Montreal.Raymoniie B.Poissant, Secretary.55235 2253-68 CLUB PORTUGAL DE MONTREAL Avis est donné que « CLUB PORTUGAL DE MONTREAL \", incorporée en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 17 mars 1966, a transporté son siège social du », est avenue Mont-Royal en les ville et district de Montréal au 4397.boul.St-Laurent en les ville et district de Montréal.Montréal, ce 21e jour du mois de novembre 1973.(Sceau) Le président.José C.Da Silva.55236-o 937-66 CLUB PORTUGAL DE MONTREAL Notice is herebv given that \"CLUB PORTUGAL DE MONTREAL \".incorporated under Part III of the Companies Act, by letters patent dated March 17th 1966.has moved its head office from 5, Mont-Royal Avenue East in the City and District of Montreal, to 4397, St-Laurent Blvd.in the City and District of Montreal.Montreal, this 21st day of November 1973.(Seal) José C.Da Silva, President.55236-0 937-66 LES ENTREPRISES RVYI'ROC INC.RAYPROC ENTERPRISES INC.Avis est donné que la compagnie « LES ENTREPRISES RAYPROC INC - RAYPROC ENTERPRISES INC.\", constituée en corporation par lettres patentes datées du 19 octobre 1973, a son bureau chef au 2381 rue St-Antoine à Lachinc.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau chef.Donné à LaSalle.ce 27 novembre 1973.Le président.5523S-0 Raymoni» Marie Pomkblkai .LES ENTREPRISES RAYPROC INC.RAYPROC ENTERPRISES INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES RAYPROC INC.\u2014RAYPROC ENTERPRISES INC.\" incorporated by letters patent, dated October 19, 1973.has established its head office at 2381 St.Antoine Street, in Lachine.From and after the date of the present notice, said office shall be considered by the Company as being its head office.(liven in LaSalle, this 27th of November.197.3.RaymoNIi M abie PoMERLEAl, 5523S President. 7566 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.La compagnie « DORAIS.LUSSIER CONSTRUCTION INC.» donne avis qu'elle a change son siège social du numéro 133, rue Principale, Saint-Édouard, à Saint-Michel.Le président, Roger Dorais.55237-0 722259 DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"DORAIS, LUSSIER CONSTRUCTION INC.\" has transferred its head office from 133 Principale Street, St.Edouard, to St.Michel.Roger Dorais, President.55237 722259 L.FRANKEN INC.La compagnie « L.FRANKEN INC.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 5011.chemin Reine-Marie.Montréal, au numéro 7005, chemin Kildare, Côte-Saint-Luc.La secrétaire, Mari.ene Fkanken.55239 5134-68 L.FRANKEN INC.Notice is given that \"L.FRANKEN INC.\" has transferred its head office from 5011 Queen Mary Road, Montreal, to 7005 Kildare Road, Côte-Saint-Luc.Marlexb Franken, Secretary.55239-0 5134-68 G.C.KNITTING INC.Avis est par les présentes donné que « G.C.KNITTING INC.\u2022\u2022, constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes en date du 31 décembre 1964.et subséquem-ment modifiée par lettres patentes supplémentaires en date du 17 juillet 1973.a changé sa principale place d'affaires dans la province de Québec, de 545 rue St-Paul La Providence, Québec, à 220 rue Hubert La Providence, Québec.Daté à Montréal, ce 22ième jour de novembre, 1973.(Sceau) Le president, céraro côté.55240-o 4860-64 G.C.KNITTING INC.Notice is hereby given that \"G.C.KNITTING INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act.by letters patent dated December 31, 1964, and subsequently amended by supplementary letters patent dated July 17, 1973, has transferred its principal place of business in the Province of Québec from 545 St.Paul Street, La Providence, Québec, to 220 Hubert Street, La Providence, Québec.Dated in Montreal, this 22nd day of November, 1973.(Seal) Gérard Côté, President.55240 4860-64 GARDERIE COOPERATIVE ST-JEAN-BAPTISTE Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement spécial adopté le 31 octobre 1973 de l'association coopérative « CARDERIE COOPERATIVE ST-JEAN-BAPTISTE \u2022 changeant son siège social, de 485, rue St-Jean, Québec, dans le district électoral de Jean-Talon, à 804.rue D'Aiguillon, Québec, dans le district électoral de Taschereau.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).55241-0 Albert Jkssop.GARDERIE COOPERATIVE ST-JEAN-BAPTISTE Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and cooperatives, has approved the special bvlaw adopted on October 31, 1973 bv \"GARDERIE COOPERATIVE ST-JEAN-BAPTISTE\", a cooperative association, changing its head office from 485 St.Jean Street, Québec, in the Electoral District of Jean-Talon, to 804 D'Aiguillon Street, Québec, in the Electoral District of Taschereau.Albert Jkssop, .Irling Deputy Minister of Financial Institutions, 55241 Companies and Cooperatives.INOV IMPORTEX INC.La compagnie « INOV IMPORTEX INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 356, rue Wellington sud, Sherbrooke, au numéro 3250, boulevard Métropolitain est, Montréal.Le secrétaire, JkaX RlVAKD.55242-0 3788-70 INOV IMPORTEX INC.Notice is given that \"INOV IMPORTEX INC.\" has transferred its head office from 356 Wellington Street South.Sherbrooke, to 3250 Metropolitan Boulevard East, Montreal.Jean Rivabd, Secretary.55242 3788-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105' année.n° 51 7567 MARCOUX TRANSIT INC.La compagnie « MARCOUX TRANSIT INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 61.rue St-.Iacques, Coaticook, au numéro 1145.boulevard Pitfield.Saint-Laurent.Le secrétaire-trésorier, Pali.ST-Pibrre.55243-0 5000-70 MOTEL MANOIR GERARD INC.Avis est donné que la compagnie « MOTEL MANOIR GERARD INC.» constituée en corporation par lettres patentes de la province de Québec en date du trente mai mil neuf cent soixante-treize (1973), a établi son bureau au numéro 9776, Boulevard Ste-Anne, Ste-Anne de Beaupré, P.Q.A compter de la.date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Stc-Anne de Beaupré, ce trente-et-unième jour d'octobre mil neuf cent soixante-treize (1973).IjC secrétaire.55244-0 Marc St-Gelais.MARCOUX TRANSIT INC.Notice is given that \"MARCOUX TRANSIT INC.\" has transferred its head office from 61 St.James Street, Coaticook, to 1145 Pitfield Boulevard, Saint-Laurent.Paul St-Pierre, Secretary-treasurer.55243-0 5000-70 MOTEL MANOIR GERARD INC.Notice is hereby given that the company \"MOTEL MANOIR GERARD INC.\" incorporated by letters patent of the Province of Québec, on the thirtieth day of May nineteen seventy-three (1973), as established its office at number 9776, Ste.Anne Boulevard, Ste.Anne of Beaupré, P.Q.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Ste.Anne of Beaupré, this thirty-first day of October nineteen seventy-three (1973).Marc St-Gelais, 55244-0 Secretary.POTERIE BONSECOURS LTEE BONSECOURS POTTERY LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie «POTERIE BONSECOURS LTEE \u2014 BONSE-SECOURS POTTERY LTD.» constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 19 juin 1973.et ayant son siège social en la Ville de Montréal, a établi son bureau principal au .427 est.rue Notre-Dame.Montreal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce 1er octobre 1973.(Sceau) La présidente.55245-q Michelle D.Léman.POTERIE BONSECOURS LTEE BONSECOURS POTTERY LTD.Notice is hereby given that the company \"POTERIE BONSECOURS LTEE \u2014 BONSECOURS POTTERY LTD.\" incorporated in the Province of Québec, under Part I of the Companies Act, by letters patent bearing the date of June the 19th, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 427 Notre-Dame Street, East, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Montreal, this first day of October 1973.(Seal) Michelle D.Lemax, 55245-0 President.SURENTEC INC.Avis est donné que la compagnie « SURENTEC INC.», constituée en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 17 mai 1973 et ayant son siège social dans la Ville de Laval, a établi son bureau au 1 Place Laval.Suite 304, à Chomedey, Ville de Laval, district de Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Laval, ce 18e jour de mai 1973.Le président.55246-0 Axdré Ai/dette.SURENTEC INC.Notice is given that \"SURENTEC INC.\", incorporated under the provisions of Part I of the Companies Act, on May 17, 1973 and having its head office in the City of Laval, has established said office at 1 Place Laval, Suite 304, in Chomedey, City of Laval, District of Montreal.From and after the date of the present notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Given in Laval, this 18th day of May, 1973.Axdré Audbtte.55246 President. 7568 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 TAPIS & GARNITURES WEINBERG & FRERES INC.WEINBERG BROS.CARPET & FURNISHINGS INC.A.VJ8 est donné par les présentes que la compagnie « TAPIS & GARNITURES WEINBERG & FRERES INC.- WEINBERG BROS.CARPET & FURNISHINGS INC.% constituée en corporation par lettres patentes en date du 15e jour de janvier 1948, et ayant son siège social en la ville de Montréal, où son bureau était situé au numéro 6344.avenue Victoria, a transféré ledit bureau au numéro 12251, boulevard Laurentien, en les ville et district de Montréal, province de Québec.A compter de la date du présent avis, leditburcau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Fait à Montréal, ce 22e jour de novembre 1973.(Sceau) La secrétaire, Deborah Korman*.55247 1482-48 LES VERGERS MILTON INC.La compagnie « LES VERGERS MILTON INC.\u2022 donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 820, Tour de la Bourse, Montréal, à Sainte-Cécile-de-Milton, Bedford.Le secrétaire, réjean\" R.i.efrançois.55248-0 2908-69 RICHARD ADAMS LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « RICHARD ADAMS LTEE » constituée en corporation dans la province de Québec, en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, par lettres patentes portant la date du 23 février 1973, et ayant son siège social en la Ville de Montréal, a établi son bureau principal au 1500 est, de Maisonneuve.Montréal.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Montréal, ce 21e jour de septembre 1973.(Sceau) Le président.55249-0 Richard Beaidin.T\\PIS & GARNITURES WEINBERG & FRERES INC.WEINBERG BROS.CARPET & FURNISHINGS INC.Notice is herebv given that \"TAPIS & GARNITURES WEINBERG & FRERES INC.\u2014 VV EIN-BERG BROS.CARPET & FURNISHINGS INC., incorporated by letters patent on the 15th day of January, 1948, and having its head office in the City of Montreal, where its office was situated at 6344 Victoria Avenue, has moved it to 12251 Laurentian Boulevard, in the City and District of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being the head office of the Company.Dated at Montreal, this 22nd day of November, 1973.(Seal) Deborah Korman.Secretary.55247-0 H82-48 LES VERGERS MILTON INC.Notice is given that \"LES VERGERS MILTON INC.\" has transferred its head office from 820 Stock Exchange Tower, Montreal, to Ste.Cécile-de-Milton, Bedford.réjeax R.Lefrançois, Secretary.5524S 2908-69 RICHARD ADAMS LTEE Notice is herebv given that the company \"RICHARD ADAMS LTEE\" incorporated in the Province of Québec, under Part I of the Companies Act, by letters patent bearing the date of February 23, 1973, and having its head office in the City of Montreal, has established its office at 1500 de Maisonneuve, East, Montreal.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the Company as being its head office.Montreal, this 21st day of September 1973.(Seal) Richard Beaudin, 55249-0 President.Avis divers Miscellaneous Notice Ville de Montréal .lei's de rachat Aux détenteurs des obligations payables en monnaie des États-Unis de l'émission désignée « 5) 'i% Sinking Fund Debentures for Public Works, due February 1.1991 » de la Ville de Montréal, province de Québec.< 'anada.City of Montréal Notice of redemption To the holders of Debentures payable in United States Currency of the issue designated \"5,,\"2% Sinking Fund Debentures for Public Works, due February 1.1991\" of the City of Montreal.Province of Québec, Canada. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, n° 51 7569 AVIS.PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNE que la Ville de Montréal a l'intention de racheter et rachètera POUR FINS D'AMORTISSEMENT le 1er février 1974, conformément aux dispositions des Obligations, les Obligations suivantes (ou partie de ces Obligations) comme mentionné ci-après, de l'émission mentionnée ci-dessus, à 100% de leur montant en principal plus l'intérêt couru à la date de rachat, à savoir: Numéros des obligations entièrement immatriculées portant le préfixe RE, rachetables le 1er février 1974 jusqu'à concurrence du montant en principal apparaissant vis-à-vis chacun des numéros suivants: 5126.$200,000 5129.S 2,000 5131.S 1.000 5134.8 4.000 5141.$ 40.000 5142.$ 30.000 5151.S 30,000 5155.?20.000 Numéros des obligations à coupons: .fiiriin numéro Les obligations (ou partie de ces obligations) ainsi rappelées pour rachat, deviendront dues et payables et seront payées en telles espèces ou monnaie des Etats-Unis d'Amérique qui, au moment du paiement, aura cours légal pour le paiement des dettes publiques et privées dans lesdits États-Unis d'Amérique, au bureau de Bank of Montreal Trust Company ou de The Royal Bank of Canada Trust Company, Borough of Manhattan, Ville et État de New-York, États-Unis d'Amérique, sur présentation et remise des obligations portant les numéros mentionnés ci-dessus, et dans le cas d'obligations à coupons, avec tous les coupons échéant après le 1er février 1974 attachés.Les obligations entièrement immatriculées et les obligations à coupons immatriculées quant au principal doivent être accompagnées de procuration pour leur transfert dûment exécutée en blanc.Les obligations entièrement immatriculées représentant la partie non rachetée de toute obligation rachetée en partie seulement seront émises sans frais.Les obligations immatriculées seront immatriculées de la même manière que les obligations remises à moins d'instructions d'agir différemment.Avis public est aussi par les présentes donné que l'intérêt sur le montant en principal des obligations (ou partie de ces obligations) présentement appelées pour paiement cessera de s'accroître le et après le 1er février 1974.Daté à Montréal, ce septième jour de décembre 1973.Ville de Montréal.Roger Bélanger.55273-0 Directeur de» finance».PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Montreal intends to and will redeem for SIN ICING FUND PURPOSES on February 1, 1974, pursuant to the provisions of the Debentures, the following Debentures (or portions thereof) as indicated, of the al>ove mentioned issue, at 100% of principal amount plus accrued interest to the redemption date, namely: Numbers of the Fully Registered Debentures bearing the prefix RE, redeemable on February 1, 1974 to the extent of the principal amount shown against each of the following numbers: 5284.$ 12,000 5285.$ 4,000 5306.$ 73,000 5308.S 40,000 5309 .8142,000 5315.$ 18,000 5316.$ 12,000 5317.8 10,000 Numbers of the Coupon Debentures: None Debentures (or portions thereof) to be so redeemed, will become due and payable and will be paid in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment is legal tender for public or private debts in said United States of America, at the office of Bank of Montreal Trust Company or of The Royal Bank of Canada Trust Company, in the Bororgh of Manhattan, City and State of New Y'ork, United States of America, upon presentation and surrender of Debentures bearing the above mentioned numbers, and in the case of Coupon Debentures with all coupons maturing after February 1, 1974 attached.Fully Registered Debentures and Coupon Debentures registered as to principal must be accompanied by assignments for transfer powers duly executed in blank.Fully Registered Debentures representing the unredeemed portion of any Debenture redeemed in partonly will be issued without charge.Registered Debentures will be registered in the same manner as the Debentures surrendered in the absence of other instructions.Public notice is also hereby given that all interest on the principal amount of the Debentures (or portions thereof) presently called for payment for payment will cease to accrue from and after February 1, 1974.Dated at Montreal, this seventh day of December, 1973.City of Montreal.Roger Bélanger, 55273-u Director of Finance.5158 .8 20,000 5164.$ 2,000 5186.S 2,000 5192.S 6,000 5214.S 20,000 5233.S 8.000 5247.S 20,000 5258.S 4,000 7570 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, So.51 CORPORATION DU CIMETIERE DE VAL D'OR CORPORATION DU CIMETIERE DE VAL D'OR Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des corporations de cimetières catholiques romains, Statuts refondus, 1964, chapitre 308.il a accordé des lettres patentes en date du 5 novembre 1973, constituant en corporation de cimetière, sous le nom de « CORPORATION DU CIMETIERE DE VAL D'OR », les corporations suivantes: « La fabrique de la paroisse St-Sau-veur», « La fabrique de la paroisse Notrc-Dame-du-Rosaire-de-Fatima », « La fabrique de la paroisse St-Joseph », « La fabrique de la paroisse St-Charles-Bor-romée », « La fabrique de la paroisse Ste-Lucie », « La fabrique de la paroisse St-Bernard » et « La fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Route ».Le siège social de la corporation est situé au numéro 533, 3e Avenue, Val d'Or, district judiciaire d'Abitibi.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives {par intérim), Albert .Iessoi*.55210-o CIM: 2-73 The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under the Roman Catholic Cemetery Corporations Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 308, he has granted letters patent dated November 5.1973, constituting into a cemetery corporation under the name of \"CORPORATION DU CIMETIERE DE VAL D'OR\", the following corporations: \"The Fabrique of the Parish of St.Sauveur\", \"The Fabrique of the Parish of Notre-Damc-du-Rosai-re-de-Fatima\", \"The Fabrique of the Parish of St.Joseph\", \"The Fabrique of the Parish of St.Charles-Bor-romée \", \"The Fabrique of the Parish of Ste.Lucie\", \"The Fabrique of the Parish of St.Bernard\" and \"The Fabrique of the Parish of Notre-Dame-de-la-Route\".The head office of the corporation is located at 533-3rd Avenue, in Val d'Or, Judicial District of Abitihi.Albert Jessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.55210 CIM : 2-73 CLUB AUTO NEIGE DE JOLIETTE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 13e jour de septembre 1973, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CLUB AUTO NEIGE DE JOLIETTE », déjà constituée en corporation le ou vers le 31 mars 1971, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $50,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Joliette, district judiciaire de Joliette.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.55210-o 726760 CLUB AUTO NEIGE DE JOLIETTE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, under Part III of the Companies Act, he has granted letters patent dated, the 13th day of September, 1973, constituting as a corporation without share capital the present members of \"CLUB AUTO NEIGE DE JOLIETTE\", previously incorporated on or about March 31, 1971, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited to $50,000.The head office of the new corporation is at Joliette, Judicial District of Joliette.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.55210 726760 Demandes à la Législature Applications to Legislature La fabrique de la paroisse de St-Patrick de Montréal Avis est, par les présentes, donné que la fabrique de la Paroisse de St-Patrick, Montréal, s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec au cours de la présente session ou de la suivante, pour obtenir l'adoption d'une loi prévoyant la création d'un conseil île fabrique, un mode île nomination de ses marguilliers, l'éligibilité à cette charge et à être paroissien et la dotant de pouvoirs additionnels.Montréal, ce 21e jour de novembre, 1973.Les procureurs de la pétitionnaire.Laini;, Weldon, Courtois, Clahkson, 55226-51-4-0 Parsons, Goxthikh & Tethault.The fabrique of the Parish of St.Patrick, Montreal Notice is hereby given that the fabrique of the Parish of St.Patrick, Montreal, will apply to the Québec National Assembly during the present or next session, for the adoption of a bill providing for the creation of a fabrique council, the appointment of churchwardens, their qualifications and that of parishioners and granting it additional powers.Montreal, this 21st day of November.1973.I,aim;, Weldon, Courtois, Clahkson, Parsons, Gontiiieh & Tétraui.t, 55226-51 -4-o .UlorlUsys for the petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105' année, «° 51 7571 THE SAINT NICHOLAS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OF MONTREAL Avis est donné que « THE SAINT NICHOLAS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OF MONTREAL , corporation ecclésiastique, ayant son siège social dans la ville de Montréal, déposera au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale du Québec un projet de loi modifiant son nom en « THE SAINT NICOLAS RUSSIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF DIOCESE OF MONTREAL AND OF CANADA », en français « LA CATHEDRALE ORTHODOXE RUSSE SAINT NICOLAS DU DIOCESE DE MONTREAL ET DU CANADA », augmentant la valeur des biens immobiliers que la corporation pourra posséder de $100,000 à $5,000,000 et précisant son affiliation à l'Église Orthodoxe Russe hors frontières de la Russie.Montréal, ce 20e jour de novembre 1973.Le procureur de la requérante, 54937-48-4-o Me Jean-Piehhe Sememik.THE SAINT NICHOLAS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OF MONTREAL Notice is given that \"THE SAINT NICHOLAS RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OF MONTREAL\", ecclesiastical corporation, having its head office in the city of Montreal, will file with the Secretariate of Committee of the National Assembly of Québec, a private bill changing its name to \"THE S.VINT NICHOLAS RUSSIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF DIOCESE OF MONTREAL AND OF CANADA\", in French \"LA CATHEDRALE ORTHODOXE RUSSE SAINT NICOLAS DU DIOCESE DE MONTREAL ET DU CANADA\" increasing the value of the immovable that the corporation shall possess from $100,000 to $5.000,000 and outlining its affiliation with the Russian Orthodox Church outside Russia.Montreal, this 20th day of November 1973.Me Jean-Piekiie Semenilk.54937-48-4-o Attorney for applicant.Services de santé et services Health Services and Social sociaux \u2014 Loi sur Services \u2014 Act on CENTRE D'ACCUEIL ORMSTOWN-HUNTINGDON Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE D'ACCUEIL OR M STOW N-HUNTINGDON ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « Centre d'Accueil ».Le siège social de l'établissement est à Ormstonn, district judiciaire de lieauharnois.Le ministre des institutions financières.compagnies et cooperatives, William Tetley.55210-o SS: 71-73 CENTRE D'ACCUEIL DE BUCKINGHAM Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement public sous le nom de \u2022 CENTRE D'ACCUEIL DE BUCKINGHAM ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « Centre d'Accueil ».Le siège social de l'établissement est à Buckingham, district judiciaire de Hull.I* ministre des institutions financières.compagnies et coopérai ires.William Tetley.55210-o SS: 68-73 CENTRE D'ACCUEIL ORMSTOWN-HUNTINGDON The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent instituting an establishment under the name of \"CENTRE D'ACCUEIL ORMS-TO WN- HU NT1NG DON \".This establishment public shall be classified as a \"Reception Centre\".The head office of the establishment is at Ormstown, judicial district of Beauharnois.William Tetley.Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.55210 SS: 71-73 CENTRE D'ACCUEIL DE BUCKINGHAM The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent constituting a public establishment under the name of \"CENTRE D'ACCUEIL DE BUCKINGHAM\".This public establishment shall be classified as a \"Reception Centre\".The head office of the establishment is located in Buckingham, judicial district of Hull.William Tetley, Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.55210 SS: 68-73 7572 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1973, Vol.105, No.51 RESIDENCE DORCHESTER Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la \\a>\\ sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de novembre 1973, convertissant la corporation « RESIDENCE DORCHESTER », constituée le 7 juillet 1969, en vertu de la troisième partie de la I,oi des compagnies, en un établissement public sous le nom de « RESIDENCE DORCHESTER».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « Centre d'Accueil ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives, William Tetley.55210-o SS: 70-73 RESIDENCE DORCHESTER The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971,_he has granted letters patent dated November 21, 1973, converting \"RESIDENCE DORCHESTER\", incorporated on July 7, 1969, pursuant to l'art III of the Companies Act, into a public establishment under the name of \"RESIDENCE DORCHESTER \".This public establishment shall be classified as a \"Reception Centre\".The head office of the establishment is located in Montreal, judicial district of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.55210 SS: 70-73 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses CUTTER LABORATORIES, INTERNATIONAL CUTTER LABORATORIES, INTERNATIONAL Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « CUTTER LABORATORIES, INTERNATIONAL », a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est la maison C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), Albert Jkssop.55210 PA: 82-73 Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CUTTER LABORATORIES, INTERNATIONAL\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec Judicial District of Québec.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalives.55210-o PA: 82-73 CONCORD AIR FREIGHT SYSTEM LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « CONCORD AIR FREIGHT SYSTEM LTD.», a été autorisée à exer-«*îr son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie est monsieur Howard J.Kaufman, avocat, 800, Carré Victoria, Suite 720, Montréal Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à la voie « B », aéroport international de Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim), Albert Jessop.55210 PA: 87-73 CONCORD AIR FREIGHT SYSTEM LTD.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CONCORD AIR FREIGHT SYSTEM LTD.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Howard J.Kaufman, Advocate, 800 Victoria Square, Suite 720, Montreal.The principal office of the company in the Province is at Road \"6\" Montreal International Airport, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, Companies awl Cooperalives.55210-o PA: \"87-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 décembre 1973.105- année.n° 51 ,\"573 BARBER OIL NORTHERN, INC.Avis est donné que, le 27e jour d'août 1973, un nouveau permis a été accordé par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, à la compagnie « BOCADEL OIL CORPORATION ».l'autorisant ù faire des affaires dans la province sous son nouveau nom de « BARBER OIL NORTHERN, INC.», en vertu des dispositions de la lx>i des compagnies étrangères, chapitre 282 des Statuts refondus de 1964.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jessop.55210 PA: 51-71 BARBER OIL NORTHERN, INC.Notice is given thai, on 27th day of August.1973.a new license was granted liy the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"BOCADEL OIL CORPORATION\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"BARBER OIL NORTHERN, INC.\", pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.Albert Jessop, Acting Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperalives.55210-o PA: 51-71 FORNEY WELDING EQUIPMENT & SUPPLIES, LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 26e jour d'octobre 1973, il a accordé un nouveau permis à la compagnie « FORNEY ARC WELDERS LIMITED ».l'autorisant à exercer son commerce dans la province «le Québec sous son nouveau nom de « FORNEY WELDING EQUIPMENT & SUPPLIES, LTD.-, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus.1964.chapitre 282.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives (par intérim).Albert Jesikip.55210 PA: 985-60 FORNEY WELDING EQUIPMENT & SUPPLIES, LTD.Notice is given that, on 26th day of October, 1973, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, to \"FORNEY ARC WELDERS LIMITED\", authorizing it to carrv on business in the Province under its new name of \"FORNEY WELDING EQUIPMENT & SUPPLIES, LTD.\".pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.Albert Jessop, Acting Deputy Minister af Financial Institutions, Companies and Cooperatives.552I0-o PA: 985 60 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-JEANNE-D'ARC (LAC-SAINT-JEAN-OUEST) MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF SAINTE-JEANNE-D'ARC (LAC-SAINT-JEAN-OUEST) Avis est donné qu'en vertu île l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois de 1966 - 1967), le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en date du treizième jour de novembre 1973, constituant en corporation sans but lucratif: Gaston Morin.entrepreneur; Cyrice Santerre, chauffeur d'autobus scolaires: Roland Lambert, rembourreur; Raymond St-Gelais, garde-forestier et Gerry Côté, menuisier, tous domiciliés à Sainte-Jeanne-d'Arc; pour les fins suivantes: acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire du village de Sainte-Jeanne-d'Arc, district judiciaire de Roberval.Société d'habitation du Québec.Le secrétaire.55227-0 Me Jean-Lit Lesaue, notaire.OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAINTE-JEANNE-D'ARC (LAC-SAINT-JEAN-OUEST) MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF SAINTE-JEANNE-D'ARC (LAC-SAINT-JEAN-OUEST) Notice is given that under Article 55 of the Quebec Housing Corporation Act (1966- 1967.Chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the thirteenth day of November 1973.incorporating as a non-profit corporation: Gaston Morin, contractor; Cyrice Santerre.driver of schoolhus; Roland Lambert, upholsterer; Raymond Si-Gelais, forest-ranger and Gerry Côté, carpenter; all are living in Sainte-.Ieanne-d'Arc (Lac-Saint-Jean-Ouest); for the following purposes: to construct and to administer low rental lodging buildings for persons of low income.The head office of the corporation is within the limits of the territory of the municipality of Sainte-Jeanne-d'Arc.judicial district of Roberval.Québec Housing Corporation, Me Jean-I.lc Lesace, notary.55227-o Secretary. 7574 QUÉBKC OFFICIAL GAZETTE.December 22.1973.Vol.106.No.51 Compagnies étrangères Agent MEEHANITE WESTERN HEMISPHERE, INC.Avis est donné que, en vertu d'une nouvelle procuration en date du 28 septembre 1973, dont copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, monsieur Walter Koze-lecki, du 450.avenue Racine.Dorval, a été nommé afin de remplacer monsieur W.1.Bradley, à titre d'agent principal dans la province de la compagnie « MEEHANITE WESTERN HEMISPHERE, INC.compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Avis est également donné qu'en vertu de la nouvelle procuration mentionnée ci-dessus, le siège social de ladite compagnie est établi au numéro 2088, avenue Cliartier, Dorval.district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et ronpfratires (par intérim), Ai.beht JcTJBOF.552(55 PA: 14-63 Extra-Provincial Companies Agent MEEHANITE WESTERN HEMISPHERE, INC.Notice is given that, by new power of attorney dated September 28.1973.a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions.Companies anil Cooperatives.Mr.Wlater Kozelecki.450 Racine Avenue.Dorval.was appointed to replace Mr.\\\\.J.Bradlev as chief agent in the Province of \"MEEHANITE WESTERN HEMISPHERE.INC.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Quebec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above-mentioned new power of attorney, the head office of the said company is established at 2088 Chartier Avenue.Dorval, judicial district of Montreal.Albert Jessop.Acting Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.55265-e PA: 14-63 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance LA SOCIETE ANONYME FRANÇAISE DE REASSURANCES Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que la « SOCIETE ANONYME FRANÇAISE DE REASSURANCES >, enregistrée sous le numéro 757 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1775 qui l'autorise à compter du 19 septembre 1973, à effectuer dans la province de Quélwc des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants, mais par voie de réassurance seulement: Automobile: biens et responsabilité.Le siège social de la compagnie est situé à 34.boulevard de Courcelles, Paris 17e.France.La compagnie a nommé M.Ralph Davis, C.A., 500, place d'Armes, Suite 2723, Montréal 126, son procureur dans la province.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 28 novembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le surintendant des assurances, 55207-50-2-O ROOKR-A.Camarairk.LA SOCIETE ANONYME FRANÇAISE DE REASSURANCES Notice of Issue of Licence and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"SOCIETE ANONYME FRANÇAISE DE REASSURANCES\", registered under number 757, has obtained the licence and certificate of registry number 1775, authorizing it as from the 19th of September 1973.to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes, but by way of reinsurance only: Automobile: property and liability.The head office of the company is situated at 34 De Courcelles Boulevard, Paris 17th\", France.The company has appointed Ralph Davis.C.A., 500, Place d'Armes, Suite 2723, Montreal 126, its attorney in the Province.(iiven at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Coo-¦x-ratives.the 28th of November 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roc.eh-A.Camahaire.55207-50-2-o Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1973, 105- année, n' 51 7575 LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE COMTE DE STANSTEAD Avis d'annulation de permis et de certificat d'en régi si rement Attendu que « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE.COMTE DE STANSTEAD », a cessé de faire affaires dans le Québec depuis le 30 juin 1973; Attendu que le président et le secrétaire-trésorier de ladite compagnie ont produit au Service des assurances, le 19 novembre 1973.une déclaration assermentée à l'effet que la compagnie a annulé toutes ses polices, payé toutes ses dettes et distribué son surplus; En conséquence, avis est par les présentes donné qi:e les permis et certificat d'enregistrement de « LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE, COMTE DE STANSTEAD », sont annulés à compter du 30 juin 1973.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 19 novembre 1973.Pour le Ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances.55124-50-2-o Rooeh-A.Camaraike.LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE COMTE DE STANSTEAD Sotice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas the \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE.COMTE DE STANSTEAD\", has ceased to do business in Quebec as from the 30th of June 1973: Whereas the President and the Secretary-Treasurer of the said company have filed, on the 19th of November 1973.with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that the company had cancelled all its policies, discharged all its debts and distributed its surplus; Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of the \"LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE LE FEU DE LA PAROISSE DE SAINT-HERMENEGILDE.COMTE DE STANSTEAD\".are cancelled as from the 30th of June 1973.Given at the office of the Insurance Branch.Department of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, the 19th of November 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Rooer-A.Camaraire.55124-50-2-o Superintendent of Insurance.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for La commission scolaire de Port-Alfred Siège social: 951, avenue Mathieu, Port-Alfred Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean-Baptiste Hudon.directeur-général, Centre Administratif, 951, avenue Mathieu, Port-Alfred, comté de Dubuc, P.Q- jusqu'à 7.30 heures du soir, jeudi le 10 janvier 1974 pour l'achat de $322,500 d'obligations pour la commission scolaire de Port-Alfred, comté de Dubuc, datées du 1er février 1973 et remboursables en série du 1er février 1975 au 1er février 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-annuellement les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau «l'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1974.The Port-Alfred School Board Head Office: 951 Mathieu Avenue, Port-Alfred Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned Jean-Baptiste Hudon.Director-General, at the Administration Centre.951 Mathieu Avenue, Port-Alfred.County of Dubuc, Québec, until 7:30 p.m., on Thursdav, January 10, 1974, for the purchase of a bond issue of $322,500 for the Port-Alfred School Board.County of Dubuc, dated February 1, 1974 and redeemable serially from February 1, 1975 to February 1, 1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on February 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February I, 1974. 7576 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, December 22, 1073, Vol.105, No.61 Tableau d'amortissement \u2014 $322,500 \u2014 10 ans Date Capital 01 02 1975.$ 21,500 01 02 1976.23,000 01 02 1977.25,000 01 02 1978.28.000 01 02 1979 .30,000 La commission scolaire de Port-Alfred, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la I/>i des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64) demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis.entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Port-Alfred s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er février 1974, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 16 octobre 1973 \u2014 $322,500\u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue jeudi, le 10 janvier 1974, à 7.30 heures du soir, Centre Admi-nistatif, 951 avenue Mathieu, Port-Alfred, comté de Dubuc, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Port-Alfred (Comté de Dubuc), ce 3 décembre 1973.Le direcleur-gênéral, M.Jean-Baptiste Hidon.Centre Administratif, 951, avenue Mathieu, Port-Alfred, Comté de Dubuc.P.Q.Téléphone: 544-3307, code 418.55215-0 Iteilemplion table \u2014 $322,500 \u2014 10 years Date Capital 01 02 1980.$ 33,000 01 02 1981.36,000 01 02 1982.39,000 01 02 1983.42,000 01 02 1984.45,000 The Port-Alfred School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the alx>ve table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to l%of the amount of the loan.The Port-Alfred School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after February 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated October 16, 1973 \u2014 $322,500 \u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Thursday, January 10, 1974, at 7:30 o'clock p.m., at the Administration Centre, 951 Mathieu Avenue, Port-Alfred, County of Dubuc, Québec.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Port-Alfred, (County of Dubuc), December 3, 1973.Mr Jean-Baptiste Hudon, Director-General.Administration Centre, 951 Mathieu Avenue, Port-Alfred.County of Dubuc, Québec.Telephone: 544-3307, code 418.55215 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1973.105' année, n' 51 Ville de Pointe-Galineau Comté de Papineau Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Louis Lamarche, greffier, Hôtel de ville, 5, boulevard du Progrès, Pointe-Gatineau, comté de Papineau, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 8 janvier 1974, pour l'achat de $1,650.500 d'obligations de la ville de Pointe-Gatineau.comté de Papineau.datées du 1er février 1974 et remboursables en série du 1er février 1975 au 1er février 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%.ni supérieur à 9%.payable semi-an mu-lli un ni les 1er février et 1er août de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,650.500 \u2014 20 ans Date Capital 01 02 1975.$ 44.500 01 02 1976 .50.000 01 02 1977 .52.000 01 02 1978 .59.000 01 02 1979 .62.000 01 02 1980 .67,000 01 02 1981.71,000 01 02 1982 .76,000 01 02 1983 .84.000 01 02 1984.92.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série là 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $173.000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant ci-haut, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er février 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Town of Pointe-Gatineau County of Papineau Public notice is hereby given that scaled tenders marked \"Tenders of bonds\" will be received by the undersigned, Louis Lamarche.Town Clerk, at the Town Hall.5 du Progrès Boulevard.Pointe-Gatineau, County of Papineau, P.Q.until 8:00 o'clock p.m.on Tuesday.January 8.1974.for the purchase of a bond issue of $1.650.500 for the Town of Pointe-Gatincau, County of Papineau.dated February 1.1974 and redeemable serially from February 1.1975 to February 1.1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on Feb-bruary 1st and August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will l>e calculated as from February 1.1974.Redemption table \u2014 $1.650.500 \u2014 20 years Date Capital 01 02 1985.$ 65.000 01 02 1986 .72.000 01 02 1987.78.000 01 02 1988 .83,000 01 02 1989 .90.000 01 02 1990 .97.000 01 02 1991.104,000 01 02 1992.111.000 01 02 1993.120.000 01 02 1994.173.000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $173.000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 1.1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the case of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. 757S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.December >>.1973.Vol.10Ô.So.51 L'échéance du 1er février 1994 au montant de 8173.000 comprend un solde de $48.000 renouvelable pour une période additionnelle de 4 ans.et échéant comme suit: Date Capital 01 02 1995.$ 11.000 01 02 1996.11.000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto et à Ottawa.Ontario.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à 8173.000.et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er février de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Pointe-Gatineau s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er février 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 244 \u2014 $183.500 \u2014 renouvellement d'emprunt: 497 \u2014 $300.000 \u2014 construction d'un aréna; 514 \u2014 $24,000 \u2014 aqueduc; 520 \u2014 $172.000 \u2014 voirie; 527 \u2014 $121.000 \u2014 voirie; 530 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduc et égouts; 531 \u2014 $14.300 \u2014 aqueduc et égouts; 532 \u2014 $99,000 \u2014 aqueduc, égouts et achat de terrain; 543 \u2014 $65,000 \u2014 construction de pavillons; 545 \u2014 $100,000 \u2014 construction d'un arena; 548 \u2014 $155,000 \u2014 honoraires professionnels; 549 \u2014 $57.500 \u2014 honoraires professionnels; 564 \u2014 $14,000 \u2014 achat de machineries; 565 \u2014 $87.000 \u2014 aqueduc et égouts; 574 \u2014 $21.000 \u2014 achat de machinerie et équipement; 575 \u2014 $32.200 \u2014 égouts; 582 \u2014 $85,000 \u2014 voirie; 616 \u2014 $20.000 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas.qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mardi, le 8 janvier 1974, Hôtel de ville.5.boulevard du Progrès, Pointe-Gatineau, comté de Papineau, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Pointe-Gatineau (Comté de Papineau), ce 7 décembre 1973.Le greffier.Louis Lamarche.Hôtel de ville.5.boulevard du Progrès, Pointe-Gatineau.(Papineau), P.Q.Téléphone: 777-2796, code 819.55214-o The maturity of February 1, 1994 in the amount of $173.000 includes a balance of $48,000 renewable for an additional 4-year period, maturing as follows: Date Capital 01 02 1997.$ 12,000 01 02 1998.14,000 The successfull tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in he Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure and at the head office of said bank in Toronto and Ottawa in Ontario.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $173.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on February 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Pointe-Gatineau agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after February 1.1974, without written authorization from the successfull tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bvlaws: 244 \u2014 $183,500 \u2014 loan renewal; 497 \u2014 $300,000 \u2014 construction of an arena; 514 \u2014 $24.000 \u2014 waterworks; 520 \u2014 $172.000 \u2014 roads; 527 \u2014 $121.000 \u2014 roads; 530 \u2014 $100,000 \u2014 waterworks and sewers; 531 \u2014 $14,300 \u2014 waterworks and sewers; 532 \u2014 $99,000 \u2014 waterworks, sewers and purchase of land; 543 \u2014 $65,000 \u2014 construction of pavilions; 545 \u2014 $100,000 \u2014 construction of an arena; 548 \u2014 $155,000 \u2014 professional fees; 549 \u2014 $57,500 \u2014 professional fees; 564 \u2014 $14,000 \u2014 purchase of machinery; 565 \u2014 $87.000 \u2014 waterworks and sewers; 574 \u2014 $21,000 \u2014 purchase of machinery and equipment: 575 \u2014 $32,200 \u2014 waterworks; 582 \u2014 $85,000 \u2014 roads: 616 \u2014 $20,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case may l>e, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, January 8.1974, at the Town Hall, 5 Du Progrès Boulevard, Pointe-Gatineau, County of Papineau, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Pointe-Gatineau (Countv of Papineau) December 7, 1973.Louis Lamarche, Tmcn Clerk.Town Hall, 5 Du Progrès Boulevard, Pointe-Gatineau, (Papineau), P.Q.Telephone : 777-2796, code 819.55214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2> décembre 1973, 105- année, n° 51 7579 Ville de Sainte-Annc-des-Monts Comté de Matane Avis | m! il n- est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pou obligations » seront reçues par le soussigné .1.I.éandre l.avoie.secrétaire-trésorier.Bureau du secrétaire-trésorier.Case postale 458, Sainte-Anne-des-Monts, comté de Matane.P.Q., jusqu'à 3.00 heures de l'après-midi, lundi, le 7 janvier 1974.pour l'achat de $795,500 d'obligations de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, comté de Matane.datées du 1er février 1974 et remboursables en série du 1er février 1975 au 1er février 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8%, ni supérieur à 9%, payable semi-an-nucllcmcnt les 1er février et 1er août de chaque année.I,e taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er février 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $795.500 \u2014 20 ans Date Capital 01 02 1975.$ 15,500 01 02 1976.16.000 01 02 1977.17,000 01 02 1978.17,000 01 02 1979.19,000 01 02 1980.19,000 01 02 1981.20,000 01 02 1982 .22.000 01 02 1983.23.000 01 02 1984.23,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série I à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur $53.000.et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er février 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Town of Sainte-Anne-des-Monts County of Matane Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, .1.I.éandre Lavoie, Secretary-Treasurer, Office of the Secretary-Treasurer, Post Office Box 458, Sainte-Anne-des-Monts, County of Matane, P.Q., until 3:00 o'clock p.m.on Monday.January 7.1974, for the purchase of a liond issue of $795.500 for the Town of Sainte-Anne-des-Monts.County of Matane, dated February 1, 1974.anil redeemable serially from February 1.1975 to February 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 8%, nor more than 9%, payable semiannually on February August 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from February 1, 1974.Redemption table \u2014 $795,500 \u2014 20 Years Date Capital 01 02 1985.S 24,000 01 02 1986 .26.000 01 02 1987 .27.000 01 02 1988 .29.000 01 02 1989 .21.000 01 02 1990.17.000 01 02 1991 .18.000 01 02 1992 .20,000 01 02 1993 .22,000 01 02 1994.400,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $53.000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of February 1, 2004 to the renewable part hereinafter mentioned. QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, December 22.1073.Vol.105, No.51 7.-.su ( «-pendant.1rs soumissions ne devront rire traiismi-ses que pour un seul «les moiles «l'émission ci-liaut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er février 1994 au montant de $400,000 comprenil un solde de $377.000 renouvelable pour une périoile additionnelle de 10 ans.et échéant comme suit : Date Capital 01 02 1995.$ 25.000 01 02 1990.28.000 01 02 1997 30.000 01 02 1998 .32.000 01 02 1999 .35,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix inili«|iié ilans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales «lans la province de Québec «le la banque ilont le nom est mentionné dans la procédure «l'emprunt.lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $400.000 et seul cet excellent sera rachet.-.ble par anticipation au pair le 1er février de chaque année pour le montant annuel reipiis pour les fins de l'amortissement «le l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à \\% du montant de l'emprunt.La ville de Stc-Annc-des-Monts s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché cana-«lien dans les soixante jours à compter du 1er février 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 110 \u2014 $102.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 124 \u2014 877,500 \u2014 renouvellement «l'emprunt; 50 \u2014 $616,000 \u2014 réorganisation financière.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publi décembre 1973, 105' aimée, n' 51 7581 Paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin Comté de Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations 6 seront reçues par le soussigné Richard Laplante, secrétaire-trésorier, jusqu'à 7.30 heures du soir.Bureau municipal, 272.rue Principale, Saint-Thomas-d'Aquin, comté de Saint-Hyacinthe.P.Q.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.