Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 mars 1974, Partie 1 samedi 16 (no 11)
[" GAZETTE QUEBEC OFFICIELLE OFFICIAL -DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES PART 1 JURIDICAL NOTICES AM 6 8 63/ PARTIE 1 \\5 PART 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin etcontientdesavisgénéraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.S.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Quebec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Quebec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements arc payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHAULES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher JffiL1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' 11 2091 2092 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971,, Vol.106, No.11 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: 83 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, 820; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Ciiari.bs-Henri Dubê.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20.from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubê, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIA 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n° 11 2093 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4.5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ACME PAD CO.LTD.AGENCE A.B.AUTONEIGE & SPORT LTEE.AHUNSTIC TRANSPORT LTD.AJUSTEMENT LAVAL LTEE.ALBERT NOVELTY CO.ALMAR CHOCOLATES LTD.L'AMICALE FRANCO-CANADIENNE.AMOS AUTOMOBILE ACCOMODATION INC.LES ANCIENS COMBATTANTS (QUEBEC) INC.ANDAL LABORATORIES LIMITED.AQUA REVUE LTEE.LES ARTISANS D'ARGENTEUIL INC.ASCOT LEATHER GOODS LTD.L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE ROUYN-NORANDA INC.ASSOCIATION DES CABARETS ET HOTELS DE LA PROVINCE DE QUEBEC ASSOCIATION DE HOCKEY DE PLESSISVILLE INC.ASSOCIATION DES JEUNES SCIENTIFIQUES.ASSOCIATION DES PARENTS D'ETUDIANTES DU COLLEGE SOPHIE-BARAT ASTRA GREENHOUSES & FARMS LTD.LES ATELIERS D'ART LITURGIQUE LTEE.AU SABLONNET DE JONQUIERE LTEE- AU TISON D'OR INC.Montreal., St-Jérôme.Montreal.Laval.Montreal.Montreal.St-Hubert.Amos.Pont Viau.St-Romuald.THE AUSTIN YOUTH ASSOCIATION INC.1953 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1967.1969, 1971 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1951 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1957 à/to 1961 incl.1963 à/to 1973 incl.1964 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1961 à/to 1973 incl.1965, 1973.1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1962, 1963, 1968 à/to 1973 incl.Austin.1962 à/to 1973 incl.Montréal.Grenville.Montreal.Montréal.Montréal.Plessisville.Montréal.Montréal.St-Laurent.Montréal.Jonquière.Québec. 2094 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 197A, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company AUTOBUS METROPOLITAINS LTEE.B.& L.DESIGN LTD.B.S.G.INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.BEAUHARNOIS TRANSIT INC.BELAIR AUTOMOBILE LIMITEE.BELANGER AUTO (MATANE) INC.BELCOURT GOLD MINES LIMITED (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) BELIVEAU MANUFACTURING LTD.BELLE-AURA MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) J.C.BELLEY LIMITEE.BELMONT SPORTSWEAR CO.BENEDICTS CLUB INCORPORATED.BENJAMIN'S LIMITED.BERGER & CHACHTER COMPANY LIMITED.M.BERGER & SONS LIMITED.BERGERON ELECTRIC INC.BERGERON & POTEL LIMITEE.BERGER VILLE WOOD INDUSTRIES INC.BERGS (ST-JEROME) INC.BERNARD CHILDREN'S WEAR INC.J.ALPHONSE BERNIER LIMITEE.BEST EVER DRESS CO.LTD.BEST LUMBER CO.THE BETHLEHEM CO.BETTER HOMES BUILDERS LIMITED.BETTER SEATS CO.BETTY BELLE LTD.BETTY & MAXIME SPORTSWEAR LIMITED.LE BIEN-ETRE SOCIAL DE QUEBEC.LE BIEN-ETRE SOCIAL DE ST-JOSEPH-D'ALMA.BIENVENUE TRANSPORT INC.BIJOUTERIE MARKO INC.J.A.BILODEAU LIMITEE.BILODEAU LIMITEE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montréal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Ste-Martine.1954 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1955, 1956, 1957, 1959 à'to 1973 incl.Materna.1973 Montreal.194S à/to 1973 incl.Trois-Rivièrcs.1948, 1954, 1956 â/o 1973 incl.Arntfield.1945, 1951 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1948.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Verdun.1949, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1947, 1948.1954 à/to 1973 incl.Sillery.1946 à/to 1973 incl.Montréal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1956, 1957, 1965 à/to 1973 incl.Québec.1945.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Québec.1943 à/to 1973 incl.St-Joseph d'Alma.1945, 1951 à/to 1973 incl.Douville.1964.1969, 1970, 1972, 1973 St-Jérôme.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Québec.1935 à/to 1939 incl.1943 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mars 1971, 106' année, n° 11 2095 Nom de la compagnie Name of the company CE.BINETTE LTEE.BIIÎDEE TOGS INC.BIRON-KNITTING MILLS LTD.BISHOP HOLDINGS LIMITED.GEORGE BIST LIMITED.BLAIS & CIE LTEE.BLANCHET & DALLAIRE LIMITEE.BLEY EMBROIDERY INC.BLOMINDON HOLDINGS LIMITED.BLOUSECRAFT INCORPORATED.BLUE BIRD SHOE LTD.BOARD OF TRADE OF THE MUNICIPALITY OF MANN.ULRIC BOILEAU & FILS LIMITEE.BOIS SUPERIEUR LIMITEE.BOISCLAIR & DRAGON LIMITED.LA BOITE DE FANTAISIE LIMITEE.J.ALPHONSE BOIVIN & COMPANY LIMITEE.MARCEL BOIVIN & COMPAGNIE LTEE.BOIVIN TRANSPORT INC.LA BONNE FOURCHETTE INC.BONNEAU AUTOMOBILE INC.BONNIE BURN CAMP LTD.BOOKMAN REALTY CO.LTD.BORDELEAU ELECTRICAL SUPPLIES LTD.BORIS FASHIONS INC.MAURICE BORTS INC.BOUCHARD & CIE (LIMITEE).D.BOUCHARD LIMITEE.BOUCHARD TRANSPORT LIMITEE.LES BOUCHERS - EPICIERS ASSOCIES LIMITEE.GERARD BOUFFARD LIMITEE.S.BOUFFARD LTEE.BOUGIE & FRERES LIMITEE.BOULANGERIE LACHUTE LTEE.BOULANGERIE ROYALE BAKERY INCORPOREE.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Québec.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Berthierville.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montebello.1948.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1951.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1945 incl.1948 à/to 1973 incl.Cross Point.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1945.1946, 1948 à/to 1973 incl.Rouleau Siding.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Loretteville.1952 à/to 1955 incl., 1957 à/to 1973 incl.Québec.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1946, 1949 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 incl.West Bolton.1946.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1949, 1952 à/to 1973 incl.St-Joseph-d'Alma 1951 à/to 1973 incl.Ste-Anne-des-Monts.1954 à/to 1973 incl.Drummondville.1946 à/to 1973 incl.Drummondville.1955,1956,1957.1959 à/to 1973 incl.G ran by.1950 à/to 1973 incl.Lévis.1963.1965 à/to 1973 incl.Cartierville.1949 à/to 1973 incl.Lachute.1949 à/to 1973 incl.Québec.1949.1963 à/to 1973 incl. 209G QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Arvida.1949 à/to 1973 incl.Val d'Or.1960 à/to 1973 incl.St-Jean.1951 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1954 à/to 1973 incl.Québec.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1952, 1954 à/to 1973 incl.Montréal.1954,1956à/to 1968incl., 1961 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1953 à/to 1973 incl.Howick.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Québec.1948 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1933, 1934, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1949 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1973 incl.Westmount.1947 à/to 1973 incl.SWoseph-Sorel.1948, 1949, 1951 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1939 incl., 1952 à/to 1973 incl.H.BOULIANNE LIMITEE.BOURCIER MOTOR SALES INC.BOURGEOIS & BOURGEOIS, LIMITEE.LA BOUTIQUE DU CADEAU DE L'HOPITAL JEAN-TALON INC.LA BOUTIQUE EL PASO INC.BOYSCRAFT LIMITED.BOYSTOWN SHIRT MFG.CO.LTD.H.E.BRADLEY COAL CORPORATION.BRAEMORE APARTMENT COMPANY.BRAIS INC.BRAM FUR CO.LTD.J, D.BRAULT LIMITEE.J.L.BRAULT LIMITEE.J.P.BRAULT LIMITEE.BRIDAL GOWNS INC.BRIDGEWATER LUMBER COMPANY LIMITED.BRIERE & BISSON LIMITEE.BRITISH CANADIAN INVESTMENT CORPORATION.BRITISH & CONTINENTAL MOTOR COMPANY LTD.BRITISH & CONTINENTAL MOTOR SALES LTD.BRITISH LOOMCRAFT (CANADA) LTD.BRITISH TEXTILES LIMITED.SAMUEL BROCK & SONS INC.BROOKSIDE INVESTMENTS LTD.BROTHERHOOD & SISTERHOOD OF TEMPLE SALOMON FREE LOAN ASSOCIATION BROUILLET SAND & GRAVEL COMPANY LIMITED.BROWMAN REALTY INC.BROWN-BOUSQUET MINES, LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) J.A.BRUCE 4 CO.LIMITED.BRUNET & MITCHELL LTEE.THE GEORGE M.BRUNTON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ALEX BRUUN LIMITED.BRUWOOD INC.BUANDERIE FEDERAL LAUNDRY LTD. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 197A, 106' année, n' 11 2097 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed BUANDERIE DES LAURENTIDES LIMITEE.LA BUANDERIE ST-LAURENT INC.LA BUCHE LTSLET, LIMITEE.BUCKINGHAM MINING CORPORATION.BUDGET FACTORS LTD.BUREAU DE COORDINATION DU TAXI.BUREAU DE CREDIT DE QUEBEC LTEE.BURGE LAKE GOLDFIELDS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) JOHN BURNS & COMPANY LIMITED.BUSSIERES & FRERES LTEE.BUTTON INDUSTRIES LIMITED.BYRD BROTHERS LTD.CM.AND T.INCORPORATED.CACHE D'OR GOLD MINES (QUEBEC) LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) CADDIE LTEE.LES CADETS DE GRAND'MERE.LES CADRES L'ECLAIR LTEE.CAFE LE CHANTE CLERC INC.CAFE LIDO LIMITEE.CAFE AND RESTAURANT HOLDERS ASSOCIATION OF THE PROVINCE OF QUEBEC CAFE ST-MICHEL LTEE.CAFE VIDEO CORP.CALDWELL FRUIT CO.LTD.CALIFORNIA KNITWEAR LTD.THE CALLWAY SASH à DOOR INCORPORATED.CAMBRIDGE TAILORS LIMITED.CAMEO SPORTSWEAR LTD.CAMEO THEATRE INC.CAMILLE INC.(ROUYN).CANADA PEAT LIMITED.CANADIENNES PALETTES LTEE.CARLTON UPHOLSTERING CO.CARTIER ESTATE CORPORATION.LE CENTRE DES LOISIRS DU CAP-DES-ROSIERS INC.Ste-Adêle-en-Haut.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.L'Islet.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.Québec.1945.1946, 1973 Val d'Or.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Normandin.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1949 incl.1952, 1955 à/to 1973 incl.Val d'Or.1946 à/to 1973 incl.Québec.1951 à/to 1973 incl.Grand'Mère.1962 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Hull.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1950, 1956 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.St-Joseph.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1954 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Rouyn.1960 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 inc!.St-Alban-du-Cap-des- 1967 à/to 1973 incl.Rosiers 2098 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971,, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company\tAdresse A ddress\tRapports non produits Returns not filed CENTRE DE LOISIRS DE ST-PAUL.\tSt-Paul-de-Montminy.\t1951, 1956 à/to 1973 incl.CHAGNON & COURNOYER.\t\t1962 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1951 à/to 1973 incl.1953 à/to 1957 incl.1962, 1964 à/to 1973 incl.LA CHAMRRR DE COMMERCE DE ST-CODEFROY\t\t CHAMPLAIN SPORTS INC.\tQuébec.\t CHATEAU MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).\t\t LA CIE DE BOIS DE STE-FELICITE LTEE.\tSte-Félicité.\t1948, 1949, 1950, 1953 \t\tà/to 1973 incl.LA CIE DE CONSTRUCTION ELITE LIMITEE.\t\t1947 à/to 1973 incl.1950, 1954 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1946 à/to 1973 incl.I A CIE D'HABITATION LTEE.\tPointe-Gatineau.\t LA CIE DE LIQUEURS CORONA LIMITEE.\t\t LA CIE DES TABACS JAUNE-CLAIR DE JOLIETTE LTEE.\t\t CINEMA VENUS INC.\t\t1955 à/to 1973 incl.1951 à/to 1973 incl.1958 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1942 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 CITADEL INVESTMENT CORPORATION.\t\t CITY MOTORS LTD.\tMontreal.\t \t\t CLASSY OF CANADA LIMITED.\tQuébec.\t CLORAS CONSTRUCTION INC.\tMontréal.\t CLUB D'AVIATION SHERBROOKE INC.\t\t LE CLUB CANADA.LIMITEE.\tSt-Jean.\t \tJonquière.\t LE CLUB DE GOLF DE LA BAIE DES CHALEURS INC.\t\t \tSt-Boniface-de-Shawi-nigan\t1971 à/to 1973 incl.CLUB OPTIMISTE METROPOLITAIN-HAUT D'ANJOU INC.\t\t1972 et/and 1973 \t\t1967 à/to 1973 incl.1964, 1966, 1968, 1973 1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1952 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1951 à/to 1973 incl.LE CLUB RAQUETTEUR L'ALGONQUIN.\t\t \tSt-Emile\t CLUB SOCIAL DES CAPILLICULTEURS DU CANADA.\t\t CLUB SOCIAL ET SPORTIF DU LAC AYLMER INC.\t\t LE CLUB SPORTIF DE DAVELUYVILLE INC.\tDaveluyville\t CLUB SPORTIF RUISSEAU ROUGE INC.\tM agog\t LE CLUB DE TENNIS DU MOULIN INC.\tCap-de-la-Madeleine.\t COLERAINE ASBESTOS LIMITED.\t\t1967 à/to 1973 incl.1950 à/to 1973 incl.COMITE CHEMIN D'HIVER DE STE-JULIE DE ST-GUILLAUME\t\t LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE NICOLET.\t\t1946 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-BONAVENTURE LIMITEE\tSt-Bonaventure-d'Upton\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, 11° 11 2099 Nom de la compagnie Name of the company LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-DENIS-SUR-RICHELIEU INC LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-OURS INCORPORE LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-ZEPHIRIN DE COURVAL INCORPORE LE COMITE DE CITOYENS DE LATERRIERE INC.COMITE DE DEVELOPPEMENT DE CABANO.COMITE D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER DE ST-BRUNO, COMTE DE KAMOURASKA COMITE DES LOISIRS STE-CECILE.COMITE DES LOISIRS DE STE-MARIE SALOME.LE COMITE DES LOISIRS DE VAL ST-PIERRE.COMITE DU MONUMENT DE LA DAUVERSIERE.COMMERCIAL ENTERPRISES INC.COMMERCIAL OPTICAL COMPANY LIMITED.COMMERCIAL RADIO LABORATORIES LIMITED.LA COMMERCIALE (INCORPOREE).COMMODITIES INCORPORATED.COMMONWEALTH COLOR AND CHEMICAL CO.LIMITED COMPAGNIE BELISLE & ALLARD LIMITEE.COMPAGNIE DE BISCUITS AETNA LIMITEE.COMPAGNIE DE BOIS BRISSON, LTEE.LA COMPAGNIE DE CONSERVES DE NAPIERVILLE, LIMITEE LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION BOUCHARD ET ROULEAU LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE ST-GUILLAUME LTEE LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SENNEVILLE & ST-ANDRE LTEE LA COMPAGNIE DES GRANDS SPECTACLES INC.LA COMPAGNIE DE PUBLICATION LE FLAMBEAU INC.LA COMPAGNIE DE TELEPHONE LOCAL DE STRATFORD LES COMPAGNONS DE L'ART.COMPTOIR DES MARCHANDS INC.LES COMPTOIRS GRENIER INC.COMPTOIR-UNIS DU QUEBEC.INCORPORE.CON-AIR-CON LIMITED.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Denis-sur-Richelieu .1951 à/to 1973 incl.St-Ours.1951 à/to 1973 incl.St-Zéphirin (Yamaska).1952 à/to 1973 incl.Laterrière.1972, 1973 Cabano.1961 à/to 1973 incl.St-Bruno.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Ste-Marie Salome.1949, 1954 à/to 1973 incl.ValSt-Pierre.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Bagotville.1948, 1950 à/to 1973 incl.Montréal.1947.1950, 1956 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.La Baie-du-Fèvre.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 incl.Rimouski.1947 à/to 1973 incl.Napierville.1953 à/to 1973 incl.St-Jérôme-de-Matane.1949 à/to 1973 incl.St-Guillaume.1946, 1949, 1950, 1952 à/to 1973 incl.Coteau Rouge.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1971 à/to 1973 incl.Stratford.1946.1956.1969 à/to 1973 incl.Rimouski.1948 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.St^Basile-le-Grand.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1948.1951.1954 à/to 1973 incl. 2100 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company CONCRETE WATERPROOFING AND RESTORATION LIMITED CONFEDERATION REALTIES INCORPORATED.CONGRESS IMPORT & NOVELTY INC.LA CONSERVERIE DE CHARLESBOURG LTEE.CONSERVERIE ST-DENIS LIMITEE.CONSOLIDATED SALES CORPORATION.CONSOLITED FUR INC.CONSTANTINEAU, PELLETIER ET WILSON, LIMITEE.LA CONSTRUCTION DE LEVIS LIMITEE.CONSTRUCTION PREFABRIQUEE LIMITEE.CONSUMERS INDUSTRIAL MINERALS, LIMITED.CONSUMERS PRODUCTS CORP.CONTINENTAL ENTERPRISES LTD.CONTINENTAL LABORATORIES INC.CONTINENTAL METALS CORPORATION.CONTRACTORS UNIFORM COMPANY LIMITED.CONVOY SILKS LTD.EMILE COOL & FILS LIMITEE.COOPER-HIRSCH INC.CORONA HOSIERY CORPORATION.CORONET GOLD MINE LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) CORONET HANDBAGS INC.LA CORPORATION DES GROSSISTES DE CHICOUTIMI.CORPORATION DE L'INSTITUT DU RADIUM DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL ET DE LA PROVINCE DE QUEBEC LA CORPORATION DES PROPRIETAIRES DU LAC DES SEPT-ILES LA CORPORATION DE PROTECTION DE DOCUMENTS.CORPORATION RECREATIVE D'OUTREMONT.CORPORATION SERVICES LTD.CORPS DE TAMBOURS ET CLAIRONS LES MARQUISES INC.COSAFI LTEE.COSMO JEWELLERY A NOVELTY CO.C.COTE LIMITEE.COTE & FILS AUTOMOBILE LIMITEE.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Montreal.1945, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1947 à/to 1973 incl.St-Denis-sur-Richelieu 1949, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1943.1960 à/to 1973 incl., 1945 à/to 1948 incl.Levis.1945.1947 à/to 1973 incl.Drummondville.1964.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1951 ù/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Terrebonne.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1943 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Verdun.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1945, 1960 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Québec.1943 à/to 1973 incl.Montréal.1944 à/to 1973 incl.Outremont.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1943,1948 à/to 1973 incl.Ste-Thérise.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.St-Hilaire.1960 à/to 1973 incl.Québeo.1948 à/to 1973 Incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1974.106- année.n° 11 2101 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed GERARD COTE AUTOMOBILES INC.St-Jovite.1948.1952.1953.1956 à/to 1973 incl.PHIL.COTE LUMBER LIMITED.Roberval.1953 à/to 1973 incl.COTE SHOE LIMITED.Montreal.1953 à/to 1973 incl.COTTON MOTOR SALES CO.LTD.Québec.1953 à/to 1973 incl.ARTHUR COUILLARD LTEE.Beauharnois.1966 à/to 1973 incl.J.A.COULOMBE A CO.LIMITED.Québec.1945.1948, 1950.1951.1957 à/to 1973 incl.COUNTRY HOUSING COMPANY.COURAGEOUS HOLDINGS LIMITED.COURVILLE & DESPAROIS LTEE.COUVRETTE & CASONI INC.CRABTREE PLASTICS LIMITED.CRAFTMILLS NOVELTIES LIMITED.CRAFTWORKS TRADING CORP.CRAVEN CLOTHES & SPORTSWEAR INC.CREATIVE ASSOCIATES INC.CREDIT INDUSTRIEL INC.LE CREDIT SOCIAL DU QUEBEC.CREMERIE M A K I l'.v I I.I.I : LIMITEE.CREMERIE NOTRE-DAME.LIMITEE.LES CUIRS TEMIS LIMITEE.THE CUSTOM SHOP INC.CYCLES GACHON INCORPOREE.DAN AUTOMATIC ALARM INC.DAISY DEE CLEANERS INC.DEL-CAT CORPORATION LTD.DI PIETRO & FRERES INC.(MOUNT-ROYAL).THE DIAMOND STEER LTD.DONNIER MANAGEMENT LTD.DORSEY-PICARD INC.ROMEO DORVAL LIMITEE.PAUL DOZOIS LTEE.DRESS CONTRACTORS ASSOCIATION.DRUMMONDVILLE ATHLETIC ASSOCIATION INC.DUBE & DUCHARME LIMITEE.DUCAS BROS.FURRIERS INC.LEDGER DECHAINE INC.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Amos.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.Parent.1965à/tol973incl.Crabtree Mills.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1950 à/to 1973 incl.Marieville.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1952 à/to 1973 incl.Témiscouata.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 inol.Montréal.1957 à/to 1973 incl.St-Basile-le-Grand.1967 à/to 1973 incl.Kepentigny.1972, 1973 Montréal.1947 à/to 1973 inol.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1957 incl.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Drummondville.1953 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 973 incl. 2102 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 197A, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Québec.1947 Jl/to 1973 incl.Québec.1954 à/to 1973 incl.La Malbaie.1958 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1972, 1973 Eastman.1945 à/to 1973 incl.Longueuil.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Alma.1973 Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Rock Forest.1969 à/to 1973 incl.Québec.193S à/to 1973 incl.Montreal.1568 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1962 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.LES ENTREPRISES JEANNE D'ARC LTEE.Montréal.1965 à/to 1973 incl.DUCHESNE & BOUCHARD LIMITEE.J.B.DUGAS INC.DUGAY FRERES LTEE.CECILE DUVAL INC.EASTMAN HARVVOOD LUMBER COMPANY LIMITED.LES EBENISTERIES LONGUEUIL LIMITEE.ECONO LIMITEE.EDGEWATER BEACH HOTEL INC.EDIBEC INC.EDIFICE GODIN LTEE.L'EDITION LA VICTOIRE LTEE.LES EDITIONS DE LA COMPETITION INC.LES EDITIONS DU MERCREDI INC.EK-CE-LAN SPORTS INC.ELECTROMATIC ENGINEERING CO.LIMITED.ENCORE-MEAT PRODUCTS LTD.LES ENTREPRISES CENTRALES INC.LES ENTREPRISES J.R.LEGAULT LTEE.St-Timothée.1964 à/to 1973 incl.Val-David.'.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Am OS.1971 à/to 1973 incl.LES ENTREPRISES LARELA INC.LES ENTREPRISES PARTICIPEX INC.LES ERECTIONS DE CHARPENTES DUBOIS INC.EXUMA LIMITED.FAROMALE INC.FELICI-PERRERA IMPORTS INC.Montréal.1966 à/to 1973 incl.FITE RITE TAILORS INC.Montreal.1953 à/to 1973 incl.FLOR-NOR EXPLORATIONS LTD.Montreal.' 1966 à/to 1973 incl.FOMA MANUFACTURERS AND AGENTS LIMITED.Lachine.1969 à/to 1973 incl.FONDEX LTEE.Gatineau.1972 et/and 1973 FORM FIT SHOULDER PAD LTD.Montreal.1963 à/to 1973 incl.FORMI-PRIX INC.St-Georges-est.1973 FOSTER CONSTRUCTION INC.Knowlton.1966 à/to 1973 incl.FOYER DE LA GAIETE DE CHICOUTIMI-NORD.Chitoutimi-Nord.1973 FRASER INVESTMENT COMPANY.Québec.1964 à/to 1973 incl.GACO INC.Laval.1966 à/to 1973 incl.ZOEL GAGNON LIMITEE.Alma.1966 à/to 1969 incl.1971 et/and 1972 .La Patrie.1951 à/to 1973 incl.GARAGE LA PATRIE INCORPOREE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, lfi mar, 1974, tW année, n° 11 2103 Nom de la compagnie Name of the company GAYMONT (INTERNATIONAL) LIMITED.GENERAL NOTIONS INC.SAMUEL GIBSON INC.GLEN VIEW FRUIT COMPANY.GLOBAL CAMPING 4 PARKING INC.GLORY SHIRT MFG.CO.LTD.THE GOLDEN PHOENIX RESTAURANT LTD.GRAD GARMENT LIMITED.GRANBY GENERAL STORE LTD.GRAWMONT MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) GRIMMER SERVICES (LIMITED).GRONDIN 4 SA VARY LIMITED.GUIGNION BROS LTD.LE GUILDE DES REGRATTIERS DU QUEBEC.HALPENNY LIMITED.L'HARMONIE CADETTE DE SHERBROOKE.HART MOTORS (CARTIERVILLE) LIMITED.HEBERT INC.HEMISPHERE TRADING CORP.HENRICO CONSTRUCTION CORPORATION.HILTOY COMPANY INC.T.F.HOGG 4 CO.LTD.HOTEL STANBRIDGE INC.HOTEL VICTORIA (TROIS-PISTOLES).HULL CONCRETE PRODUCTS LIMITED.HURON FUR DRESSERS LIMITED.I.B.I.SYSTEMS INC.LES IMMEUBLES ROUTEXPRESS INC.IMPRIMERIE-LITHOGRAPHIE CHARTRAND LTEE.L'IMPRIMEUR RAYMOND LEMAY INC.INDIAN LACROSSE CLUB LTD.LES INDUSTRIES DU BOIS INC.INDUSTRIES METALLURGIQUES DE ROXTON LIMITEE.LES INDUSTRIES OUELLET LTEE.L'INFATIGABLE.INSTITUT DE DANSE DES BOIS FRANCS INC.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1962.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1972 et/and 1973 Montreal.1942.1949.1951 à/to 1973 incl.Granby.1951.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Sillery.1950 à/to 1973 incl.Gaspé.1957 à/to 1973 inrl.Québec.1943 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1949 à/to 1973 incl.St-Laurent.1961.1957 à/to 1959 incl.1966 à/to 1973 incl.Quebec.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1949.1950 1952 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Stanbridge.1966 à/to 1973 incl.Trois-Pistoles.1966 à/to 1973 incl.Hull.1951 à/to 1973 incl.Loretteville.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Caughnawaga.1965 à/to 1973 incl.Ste-Thércse-de- 1971 à/to 1973 incl.Blainville Roxton Falls.1951 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1946, 1953 à/to 1973 incl.VictoriaviUe.1965, 1968 à/to 1973 incl. 2104 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974.Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name rtS the company J.G.AUTOMOBILE LTEE.LA JEUNE CHAMBRE DE LAPRAIRIE INC.JO-ANN BEAUTY SALON INC.LES JOINTS INDUSTRIELS METROPOLITAINS LTEE.LES JOURNAUX ASSOCIES S.F.INC.JUNIOR MAID LINGERIE MFG.KELLY MACHINE SHOP LIMITED.KRA-BERN LTD.LABORATOIRE ALGERINE LIMITEE.LES LABORATOIRES BIO-BACTO LTEE.LAC MASSON GOLD AND COUNTRY CLUB, INC.J.C.LA COMBE INC.LADY STELLA OF FIFTH AVENUE LTD.L.LAFRENIERE AUTO TIRE INC.LAITERIE CASCADE INC.J.P.LAJEUNESSE INC.LAKE ST.JOHN AND CHIBOUGAMAU TRANSPORT LAKESIDE HOMES INC.P.A.LANGELIER LIMITEE.LAROFOR INC.LAURIER REMBOURRAGE INC.LAVAGE DE VITRES CAMPEAU WINDOW CLEANING INC.S.N.LAZARUS & CO.LTD.J.ALPHONSE LEMAY INC.LEMOINE CHIBOUGAMAU MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) ADELARD A GUSTAVE LEPINE.INC.JACK LEWIS INC.LIAISON INC.LIBRAIRIE VACHON LIMITEE.LIDO PRODUCTS COMPANY LIMITED.LA LIGUE D'AVANCEMENT CIVIQUE.LIGUE INDEPENDANTE CATHOLIQUE DE MONTREAL.LA LIGUE PAN AMERICAINE DU CANADA (QUEBEC).LA LIGUE POUR LA SAUVEGARDE DE L'INDUSTRIE LIBRE Adresse Rapports non produit» Addre» Returns not filed Dolbeau.1963 à/to 1973 incl.La Prairie.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Québec.1954.1966.1969 à/to 1971 incl., 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Québec.1953, 1955 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Sorel.1972, 1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.St-Bonifare-de- 1971 à/to 1973 incl.Shawinigan Shawinigan.1968.1969.1971 à/to 1973 incl.Québec.1951.1973.Roberval.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Laval.1970 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1956.1962 à/to 1973 incl.Québec.1945, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1953, 1955 à/to 1973 incl.Montréal.1945 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1951 à/to 1973 incl.Outremont.1955 à/to 1973 incl.Québec.1947 à/to 1973 incl.Montréal .1958 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2105 Nom de la compagnie Name of the company LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE GRANBY INC.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DES TROIS-RIVIERES, INC.LIGUE REGIONALE DE BALLE MOLLE SENIOR DE LA RIVE SUD INC.LIKE-NU FUR BLENDING & DYEINS LTD.LIMOGES.PICHE, ALARIE LTEE.LIMOILOU ELECTRIQUE LIMITEE.LINDA MANUFACTURING INC.THE LINGER CORPORATION.LINGERIE « DU JOUR » INC.LINGERIE SALES INCORPORATED.LIN KO INVESTMENT LTD.JOS LIPARI LIMITEE.S.LIPSON & CO.THE LITTLE CUTIE INC.THE LITTLE THEATRE OF QUEBEC, INCORPORATED.LOCAL SALVAGE CORPORATION.LODZ ASSOCIATION.LOISIRS NOTRE-DAME.LES LOISIRS DE ST-PHILEMON INC.M.G.COMMUNICATIONS VISUELLES INC.R.MACLEAY & COMPANY LIMITED.MAIN HEBREW DELICATESSEN INC.MAISON DURY LTEE.LA MAISON ROUTHIER INC.MAMIE MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).MARCHAND CYCLO MASSAGE DE QUEBEC INC.MARCHE JARRY INC.TONY MARINI INC.PETE MARK INC.MARTIN ENGINEERING INCORPORATED.PENNY MASON (CANADA) LTD.PHILIPPE MAZIADE LTEE.METRO EXCAVATION (1966) LIMITEE.METS DE LACHINE INC.MEUBLES & QUINCAILLERIE BEAUCHAMP & FRERES INC.MIL-BOY LIMITED.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Granby.1955 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1938 à/to 1973 incl.Lauzon.1966, 1973 Montreal.1952 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1952 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1957, 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Québec.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1946 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1973 incl.St-Philémon.1972, 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.St-Jovite.1965, 1967, 1972, 1973 Trois-Rivières.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Giffard.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Québec.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Lachine.1965, 1968 à/to 1973 incl.Ormstown.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1950, 1952 à/to 1973 incl. 2106 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.March 16.1971, Vol.106.\\o.11 Nom de la compagnie Nome of the company MINOLET BRANDS INC.GEO.MINVILLE & ASSOCIES LTEE.MODERN FASHION LIMITED.MODERNFOLD (CANTONS DE L'EST) LTEE.MONALEA BEACH BUNGALOWS INC.MONICA DISTRIBUTORS INC.MONTREAL TERRAZO TILE & MARBLE LIMITED.MONTREAL TILE TERRAZO AND MARBLE EMPLOYERS' ASSOCIATION MONTY & FRERES LTEE.MOTEL LA BOURGADE INC.MULTI-DISTRIBUTION INC.NANSU MANAGEMENT CORP.NARIMAC LIMITEE.NATAKI CORPORATION.NEUVICO LTEE.NEW YORK GARMENT INC.NICK'S DISCOUNT DEPARTMENT STORE LTD.NORD-EXTERMINATION INC.NORTHAMERICAN CASING CORPORATION.NORTHERN RESORTS ASSOCIATION OF THE LAUREN-TIANS NORTHERN SALES COMPANY.NORTHERN TANK HAULERS LTD.NORTHERN TIMBER COMPANY LIMITED.NORTHMOUNT SALES LTD.NORWEGIAN WOODCRAFT LIMITED.NOUVELLE ORGANISATION EN CONSTRUCTION INC.NOVA KNITTING LIMITED.NOVA REALTIES INC.NOVA SCOTIA COAL SALES LTD.NOVAMINES CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY).NOVELTY FABRICS INC.NOVELTY HANDBAGS LIMITED.NOVELTY MFG.CO.LTD.NOVO BROOM & MOP SUPPLIES CORPORATION.NU-MODE NOVELTY INC.NUN'S ISLAND THEATRE INC.Adresse Rapports non produit» Address Returns not filed Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Québec.1952 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Marieville.1951 à/to 1973 incl.Dorion.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Neuville.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Hautcrive.1973 Montreal.1952 à/to 1973 incl.Ste-Agathe.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Lachine.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.St.John».1953 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1946, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1962.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n\" 11 2107 Nom de la compagnie Name of the company NU-STYLE CLOTHING CO.NU-TONE PRODUCTS LIMITED.NUWAY FLOOR COVERING LTD.NU-WAY FOOD PRODUCTS INCORPORATED.NU-WAY MEAT MARKET LTD.L'OEUVRE DES LOISIRS DE LA CITE DE CHICOUTIMI.L'OEUVRE DU SERVICE FAMILIAL.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEU DE ST-JEAN-PORT-JOLIINCORPOREE L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX D'ARMAGH.OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DTBERVILLE INCORPOREE.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET COLONIES DE VACANCES D'ARVIDA.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET D'EMBELLISSEMENT DE BAGOTVILLE.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE MONTMAGNY INC.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX SAINT JEAN BOSCO (O.T.J.DE JOLIETTE).L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE SAINT-LAURENT OFFICE SALES & SERVICES CO.LTD.OKA WOOD PRODUCTS LIMITED.ONAGON INVESTMENTS LIMITED.THE ONYX & METAL PRODUCTS LIMITED.THE OPTIMIST CLUB OF VERDUN INC.ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE MONTREAL ORDER SONS OF ITALY BUILDING ASSOCIATION INCORPORATED ORE MONTE MINE INC.(NO PERSONAL LIABILITY).OREMAR GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) ORFORD MINING COMPANY LIMITED.ORGUES 0.JACQUES (LIMITEE).ORIGINAL KNISH BAKERY LTD.ORIS INC.ORLAND GOLD MINES (QUEBEC) LIMITED.J.ORNSTEIN LIMITED.OSISKO LUMBER LTD.L.OSTROFF INC.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1957 incl.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1935, 1940 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1955, 1958 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 incl.St-Jean-Port-Joli.1948,1951 à/to 1973 incl.Armagh.1947 à/to 1973 incl.Iberville.1962 à/to 1973 incl.Arvida.1945, 1955, 1957 à/to 1973 incl.Bagotville.1955 à/to 1958 incl.1960 à/to 1973 incl.Montmagny.1971 à/to 1973 incl.Joliette.1964 à/to 1973 incl.St-Laurent.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1938, 1940 à/to 1973 incl.Verdun.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1948, 1958 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1946 à/to 1973 incl.Village de la 1945 à/to 1973 incl.Providence Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Rouyn.1949, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl. 2108 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Ailrrs'-e Rapports non produits Relurnt not filed Rouyn.1962 à/to 1973 incl.Marieville.1953 à/to 1973 incl.Outremont.1960 à/to 1973 incl.Val d'Or.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Outremont.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Verdun.1945 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Québec.1947 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.St-Jérflme.1964, 1966 à/to 1973 incl.Québec.1948 à/to 1973 incl.PARADIS AUTOMOBILE LTEE.Montréal.1948 à/to 1973 incl.PARADIS 4 FARLEY INC.Montreal.1938 à/to 1973 incl.PARAMOUNT CLUB INCORPORATED.Montreal.1942 à/to 1973 incl.PARAMOUNT CLUB INCORPORATED.Montreal.1960 à/to 1973 incl.PARAMOUNT FOOTWEAR LIMITED.Montreal.1943, 1955 à/to 1973 incl.PARAMOUNT LEATHER GOODS CO.INC.Montreal.1957 à/to 1973 incl.PARAMOUNT SERVICE ENTERPRISES LTD.Montreal.1955 à/to 1973 incl.PARAMOUNT TRADING CORPORATION.Montreal.1946 à/to 1973 incl.PARAPLASTICS LTD.Montreal.1949 à/to 1973 incl.PARFUMERIE L.T.PIVER LIMITEE.Montréal.1944, 1966 à/to 1973 incl.PARFUMERIE LONGCHAMPS LTD.Montreal.1946.1949 à/to 1973 incl.PARIS FUR CO.INC.Montreal.1947 à/to 1973 incl.PARIS LABO LIMITEE.Montréal.1954 à/to 1973 incl.PARISEAU 4 FILS LIMITEE.Brownburg.1968 à/to 1972 incl.LUCIEN PARIZEAU 4 CIE LTEE.Montréal.1945 à/to 1973 incl.OTTMAN GOLD MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) OUELLETTE GLOVE WORKS LTD.THE OUTREMONT CURLING CLUB INCORPORATED.OVERBURDEN DRILLING COMPANY LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) THE OVERSEAS AID ASSOCIATION, INC.THE OXFORD CLUB.P.A.T.CHEMICALS LIMITED.P.4 P.MANUFACTURING CO.LTD.EDOUARD PAGE LIMITEE.PAGE 4 PAGE LTEE.PALAIS SOHMER LIMITEE.PALM CLUB INC.PALMER REALTIES INCORPORATED.PALMERS LIMITED.PALMERS SALON LTD.PAM TRADING LIMITED.PAN CONSTRUCTION INC.PAN INVESTMENT LIMITED.PAN-AMERICAN IMPORTERS 4 EXPORTERS INC.PAPINEAU HOLDING CORPORATION.JOS PAQUET LIMITEE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n° 11 2109 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed PARK LANE GOWNS INC.PARK TOBOGGAN 4 SKI CLUB LIMITED.PARKTOWN MFG.LTD.PARKWAY AUTOMOBILES LIMITED.PASTEL GARMENT MANUFACTURING COMPANY LTD.PAT-ANN JUNIORS INC.A.W.PATENAUDE INCORPOREE.PATRICIA APARTMENTS INC.LE PATRONAGE DE JONQUIERE.LE PAVILLON DES POINTES BEAUDET LTEE.PEAR-LIT MALARTIC MINES LTD (NO PERSONAL LIABILITY).PECO DYEING INC.PEERLESS CANDIES LTD.PEERLESS FURNITURE MANUFACTURING CO.LTD.PEGGY ANN SHOPS INCORPORATED.LES PEINTURES IDEALES INC.PELCHAT - GAUTHIER LIMITEE.PELLETIER 4 CO.INC.PENNSYLVANIA ANTHRACITE COMPANY LIMITED.PEOPLE'S 5é-10ë-15é TO $1.00 STORES (OF QUEBEC CITY) LIMITED PEOPLE'S SAMPLE STORE LIMITED.PEP GAZOLINE CORPORATION.PEPPINO INC.PERFECT FIT CLOTHING INC.PERFECT QUILTING PRODUCTS COMPANY.PERFECT STYLE GARMENT CO.LTD.PERFECTION CONSTRUCTION INC.PERFECTION LAUNDRY INC.PERMACURE INC.PERMANENT SECURITIES LIMITED.PERRON ART INC.H.M.PERRON LIMITEE.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1932 à/to 1934 incl.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1945, 1949 à/to 1973 incl.Montreal.1951, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1952 à/to 1973 incl.Montréal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Jonquière.1949 à/to 1973 incl.Victoriaville.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1949, 1953 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1952 incl., 1962 à/to 1973 incl.Montréal.1947, 1948.1951, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Québec.1942 à/to 1973 incl.Montreal.1949, 1950 1954 à/to 1973 incl.Montreal.1940.1942 à/to 1973 incl.Montreal.1969, 1972, 1973 Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1951, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1971, 1973 Montreal.1948 à/to 1973 incl.Laval.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1947, 1948, 1950 à/to 1973 incl. 21 ill QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed PERSHING AMALGAMATED MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) LES PETROLES X-L LTEE.PIERREFONDS CITIZENS LEAGUE INC.PLACEMENTS J.E.ST-LAURENT INC.LES PLACEMENTS LA BARRICADE LTEE.LES PLACEMENTS SOLVA INC.LES PLACEMENTS TOULANGER LTEE.PLOMBERIE DUCHARME INC.PLOMBERIE MONTREAL LIMITEE.PLYMOUTH SALES (QUEBEC) LTD.POIRIER AUTOMOBILE LTEE.PRICING PRESS ADVERTISING INC.LES PRODUITS SANITAIRES ROMA INC.PUBLICITE ARCOBO INC.QUANTUM INDUSTRIES LTD.QUALITY BINDERS LIMITED.LES 4 ASSOCIES INC.QUEBEC FOOD COUNCIL.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1967 à/to 1973 incl.Picrrefonds.1960, 1963 à/to 1973 incl.Amos.1969 à/to 1973 incl.St-Basile-le-Grand.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.1953.1963.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Québec.1956 à/to 1973 incl.Dorion-Vaudreuil.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1972, 1973 Les Saules.1966, 1968.1972, 1973 Gaspé.1971 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Val-David.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1944, 1946 à/to 1973 incl.Montréal.1961 à/to 1973 incl.Aima.1967 à/to 1973 incl.RADIO CITE INC.RADIO FM SAGUENAY-LAC ST-JEAN LTEE.FRANK W.RAMSEY & CO.LTD.Montreal.1952 à/to 1973 incl.REPUBLIC MFG COMPANY.Montreal.1963 à/to 1973 incl.RESTAURANT LE COQUET INC.Cap Santé.1967.1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.REVETEMENTS D.S.INC.St-Raphaêl-de-1'île- Bizard RIMOUSKI LUMBER AND CONTRACTING CO.LTD.Rimouski.1952 à/to 1973 incl.RODRIGUE LTEE.ROLAINE FURS LTD.ROLLING WAGON WHEEL INC.ROMERTEX CORPORATION.Laval.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1951, 1954 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1957, 1964 à/to 1973 incl.FRANK ROUND & SON LTD.Montreal.1952 à/to 1973 incl.ROXY GARMENT CO.Montreal.1953 à/to 1973 incl.ROYAUME DES JEUNES INC.Lemoyne.1970 à/to 1973 incl.ST-PATRICK GOLF CLUB.Rivière-du-Loup.1971, 1972 et/and 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n° 11 2111 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ST.PATRICK REALTY COMPANY LIMITED.Rivicre-du-Loup.1973 STE-THECLE CONSTRUCTION LIMITEE.Ste-THècle.1963 à/to 1973 incl.SABLIERE GREGOIRE INC.SALON MARGOT INC.SAUVE AUTOMOBILE INC.SEIBERT MFG.CO.LTD.SER VET TEK INC.SERVICE DES LOISIRS DE ST-VINCENT-DE-PAUL COMTE DE LAVAL LES SERVICES FUNERAIRES DE QUEBEC INC____ SHEFFORD AUTO SERVICE INC.SHEFFORD MARBLE QUARRIES LIMITED.SHOE BAZAAR LTD.SILVER CONSTRUCTION CO.LTD.SIRLOR TEXTILE PRINTING INC.SMITH MANUFACTURING CO.SNAJARD INCORPORATED.SOCIETE LECTA INC.SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE DU DIOCESE DE VALLEYFIELD SOL BLOOMBERG REALTIES INC.SOMAL CONSTRUCTION CO.LTD.SOREL SCREEN NOVELTIES LTD.LES SPECIALITES B.C.LTEE.LES SPECIALITES DE CIMENT ET TUILE LTEE.THE STANDARD CONSTRUCTION CO.LTD.STANDARD TRIUMPH (QUEBEC) LIMITED.STATION DE SERVICE RENE F.LEBEL INC.STERLING SALES & SALVAGE CO.S.STOROZUK & SON LTD.SUPER STEEL & METAL CO.SUTTON SKI & HOLIDAY RESORT INC.TANNERIE DAIGLE LIMITEE.TAPIS DE L'EST INC.J.ALBERT TARDIF & FILS LTEE.TAYLAW CORPORATION.Ste-Mélanie.1965.1972 et/and 1973 Vaudreuil.1971 à/to 1973 incl.Deux Montagnes.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1968 à/to 1973 incl.St-Vincent-de-Paul.1950, 1954 à/to 1973 incl.Québec.1954 à/to 1956 incl.1958 à/to 1973 incl.Granby.1964, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1963, 1964, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1961, 1962.1967 à/to 1973 incl.Valleyfield.1961 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Tracy.1965 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Québec.1971 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1954 incl.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1972 et/and 1973 Montreal.1953 à/to 1973 incl.Laval.1970,1972 et/andl973 Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Québec.1950 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1970 à/to 1973 incl. 2112 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produit» Return* not filed TENANTS PROTECTIVE ASSOCIATION LIMITED TERMINUS D'AUTOBUS DE LEST LTEE.TERRASSEMENT CARTIER INC.TERREBONNE CANNING COMPANY LIMITED.TEXTILE ALSACE-MONTREAL LIMITEE.THEATRE DE LA COMEDIE CANADIENNE INC.GAETAN THERRIEN INC.THETFORD WOOD PRODUCTS LTD.NAP THOMAS LTEE.TOPAZ DRESS INCORPORATED.TOPPER FURNITURE INC.STEPHEN TORINO LIMITED.TOTS' TOGGERY INCORPORATED.TOUGAS AUTOMOBILE LIMITEE.TOUGAS & TOUGAS LTEE.F.TOURIGNY CONSTRUCTION LIMITEE.TRANS-CONTINENTAL FUR CORPORATION.TRANSIT TANKERS & TERMINALS LTD____ TRANSPORT ETUDIANT REGIONAL INC.TRANSPORT L.C.C.INC.TRANSPORT L'ACADIE LTEE.TRANSPORT DE LA VALLEE LIMITEE.TREE SURGERY COMPANY LIMITED.Montreal.1937 à/to 1973 incl.Montréal.1968.1964 à/to 1973 incl.Sept-Ile».1973 Terrebonne.1952 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.St-Sylvestre.1970 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1950 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1961, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.St-Jean.1945 à/to 1952 incl.1956à/to 1973 incl.1935 Montréal.1954 à/to 1973 incl.Malartic.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1949, 1954 à/to 1973 incl.Montreal.1941 à/to 1973 incl.Cbicoutimi.1969 à/to 1973 incl.Plaisance.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 et/and 1973 Aroqui.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Senneterre.1951 à/to 1973 incl.TRIVICOUR GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).TROIS-RIVIERES DUNBRIK LTEE-LTD.Troi»-Rivièrea.1956 à/to 1973 incl.TUBEMASTER PLASTIC CORPORATION.Montreal.1969, 1971 à/to 1973 incl.TWELVE TWELVE PINE LTD.Montreal.1967 à/to 1973 incl.UNION SOCIETY OF CANADA LIMITED.Montreal.1940 à/to 1949 incl.1961 à/to 1973 incl.UNIVERSAL CHEMICALS INC.Montreal.1947 à/to 1973 incl.UNIVERSAL WIPING PRODUCTS LTD.Montreal.1946.1949 à/to 1973 incl.USINE D'OUTILLAGE GAUTHIER LIMITEE.8t-Jértme.1955 à/to 1973 incl.VAL ROYAL TRAN8PORT LTEE.Montréal.1966 à/to 1959 incl.1964 à/to 1973 incl.VALCARTIER DEVELOPMENT INC.Québec.1948 à/to 1973 incl.VALROYAL CORPORATION.Montreal.1965 à/to 1973 incl.FERNANDO VEILLEUX INC.Vallée Jonction.1965, 1967.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n° 11 2113 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed VERDUN INDUSTRIAL BUILDING CORPORATION.FLORENT VERNER ASPHALTE LTEE.VIANDES GREBER LTEE.VICTORIA SALES LIMITED.LE VIEUX ROUET INC.VIGER GARAGE LIMITEE.LA VILLA FAMILIALE DES LACS MCLAREN ET PRATTE INC.VILLEGIATURE DU LAC CLAIR INCORPOREE.VOGUE MUSIC INCORPORATED.VORIA SPORTSWEAR LTD.VOYAGEURS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED.VULCA PROCESS CORPORATION.VULCANISATION MODERNE LTEE.VULCANSTEEL ARCHITECTURAL CONSTRUCTION LTD.WALES CLUB INC.H.WALFORD LIMITED.WALGROVE LIMITED.JAMES WALKER HARDWARE COMPANY.WALLEY LUMBER CO.LTD.WALTER HATS LTD.WARD ASBESTOS CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WARTIME ACCIDENT PREVENTION EMERGENCY SERVICE INCORPORATED.WASHINGTON CLUB INCORPORATED.WASHINGTON GOLDS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WATSON & MARTIN LIMITED.WEIR'8 GARAGE LIMITED.WEIR'S MOTOR SALES LTD.S.WEISER LTD.WELCROSS LIMITED.WELLINGTON THEATRE LIMITED.WEST AERONAUTICAL DEVICES INC.WEST SHORE GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WESTBORO INCORPORATED.WESTERN SUPPLIES LIMITED.Verdun.1964 à/to 1973 incl.St-Rémi.1962, 1964 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau.1967 à/to 1973 incl.Verdun.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1955 à/to 1973 incl.St-Côme.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1951,1953 à/to 1973 incl.Rouyn.1939 à/to 1973 incl.Montreal.1943 à/to 1973 incl.Rimouski.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1937, 1940 à/to 1973 incl.Montreal.1957, 1959 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1955.1958, 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1950, 1952 à/to 1954 incl.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1973 incl.Québec.1938 à/to 1973 incl.Montreal.1937, 1938, 1940 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1951.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Verdun.1946 à/to 1973 incl.Dorval.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1937 à/to 1973 incl.Verdun.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl. 2114 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 16.1971.Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Mime oltht company Adresse Aàdras Rapports non produits Returns not filed WESTERN TOTALIZATOR MFC INC.WESTMOUNT FURS INC.WESTMOUNT GROCERY COMPANY.WESTMOUNT PARK MANOR CORPORATION.WEXLER FRUIT COMPANY LIMITED.WHEELER CONSTRUCTION LTD.THE WHITE DAIRY MILK BAR LTD.W.H.WHITE LIMITED.WHOLESALE SOLID FUELS BUREAU INC.GEO.WHYTE INC.THE WIGWAM FISH AND GAME CLUB INCORPORATED.WILL A PILON LIMITEE.WILLIAMS SHARE CORPORATION (QUEBEC) LTD.WILLIAMS TRANSPORTATION COMPANY LIMITED.WILMOT ENTERPRISES LTD.WILSON EQUIPMENT CO LTD.GEO.R.WILSON LIMITED.WILSON MACHINERY A SUPPLY COMPANY.WILLIAM WILSON COAL CO LTD.WINDSOR ASSOCIATION INC.WINDSOR MOTOR SALES INCORPORATED.WINDSOR OIL LIMITED.WINDSOR SHOE A SLIPPER CO.WIN-SUM INN INC.WIPE-ON CORPORATION.GEORGE WISEMAN SONS LTD.WOLFE LUMBER MILLS CORP., WOMAN'S EXCHANGE OF MONTREAL INC.WONDERLAND CHILDREN'S WEAR LTD.WONDER-WOOD COMPANY LIMITED.WOODBURY CONSTRUCTION COMPANY.WOOD-CADILLAC MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WOODEN ACRES CAMPS INC.WOODEN ACRES INC.WOODLAND COMPANY LTD.Montreal.1965, 1967 A/to 1970 incl.et/and 1973 Montreal.1951 à/to 1973 incl.Westmount.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1955.1957.1959 à/to 1973 incl.Mount Royal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1956.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1936.1937.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1935, 1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Lachine.1961, 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Piedmont.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.St-Dorothée.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1942 à/to 1973 incl.Montreal.1943 à/to 1973 incl.Montreal.1943 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1974 incl.Montreal.1942 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 196S incl.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971, 106' année, n° 11 2115 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed WOODWORKERS LTD.WORLD APPLIANCES & TELEVISION CO LTD.WORLD HIGH FIDELITY RECORDING INCORPORATED.WORLD TRADING IMPORT & EXPORT CORPORATION.YATCH CLUB LTD.YAFFY SYSTEMS INC.YALE HOLDINGS LTD.YARED'S LIMITED.YELIN'S OUTFITTERS LTD.YORK CREDIT LTD.YORK MINING SYNDICATE LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).YORK SHOE LIMITED.YOUNG SOPHISTICATE INC.YOUVILLE TRADING COMPANY LIMITED.YUCCAN CAFE LTEE.YVEL JERSEY MANUFACTURING LTD.ZAHLER INDUSTRIES CORPORATION.ZELL-EM (CANADA) LIMITED.ZEPHYR RADIO CORP LTD.ZETLAND VICTORIA SQUARE GARAGE LIMITED.Montreal.1947, 1948, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1949, 1950, 1953 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1947, 1950 à/to 1973 incl.Montreal.1951, 1955 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1944 à/to 1973 incl.Montreal.1948 A/to 1973 incl.Montreal.1962.1963, 1965 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1940 à/to 1973 incl.Montreal.1933, 1935 à/to 1973 incl.56436-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56436-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom de la compagnie Dissolution Name of the Company Date A.P.M.INC.08 12 1973 L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES DU ST-LAU- 20 10 1973 RENT, INC.THE ST.LAWRENCE SHIPOWNERS ASSOCIATION, INC.BAL TARARIN, INC.25 08 1973 CLUB BOULEAU.29 09 1973 CLUB DE COURCELLES.06 10 1973 Gazette officielle No Officiai Gazette No.49 42 34 39 40 2116 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Dissolution Gazette officielle No Home of the company Date Offiexal Gazette No.CLUB DES GASPARDS INC.CLUB LA PARENTE INC.CLUB LOGAN.CLUB MISHOMIS.CLUB SOCIAL DES MOOSE DE QUEBEC INC.CLUB VANEL INC.FINDEC INVESTMENTS INC.FONDATION CHARLES LEMOYNE.GENTILLY ROAD HOU8ING CORP.GOLD MEDAL DEVELOPMENTS INC.ISSBRO INVESTMENTS INC.KRAON HOLDINGS INC.LAKE GEORGE DEVELOPMENT INC.MILAUM INVESTMENTS INC.NATISK FISH AND GAME CLUB.NESCER INVESTMENTS INC.NOARK HOLDINGS LTD.O'SULLIVAN FISH & GAME CLUB INC.P.A.R.TRANSPORT INC.REALTY FUND INCORPORATED.RESERVATION INVESTMENT CORP.ROMARCO INC.SERVOPARC INC.STELAT INVESTMENTS INC.TRIANGLE PROPERTIES LIMITED.LES PROPRIETES TRIANGLE LIMITEE VISION DEVELOPMENT LIMITED.H\til\t1973\tM 13\t10\t1973\t\u2022u 13\t10\t1973\t41 u\t10\t1973\t\u2022U 26\t08\t1973\tM 13\t10\t1973\t41 M\til\t1973\t¦Il Of,\t10\t1973\t¦10 26\t01\t1974\t4 ta\t11\t1973\t44 08\tH\t1973\t\u202211 06\t10\t1973\t40 M\t01\t1974\t4 H\t11\t1973\t44 18\t10\t1973\t\u202211 03\t11\t1973\t11 03\t11\t1973\t\u202211 M\t05\t1973\t21 03\t11\t1973\til 08\t10\t1973\t10 SO\tDO\t1973\t39 so\t10\t1973\t42 03\t11\t1973\t11 08\t11\t1973\t11 10\tn\t1973\t18 08\t10\t1073\t10 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoute en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 56436-0 Piehue Dbsjakdinb.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.PlERBE DeBJARDINB, 56436-0 Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2117 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Coopératives Lettres patentes (1\" partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and cooperatives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Norn / Name Siège social / Head Office Incorporation Date A.A 0.PSIHOGIOS LTD.A.A G.PSIHOGIOS.\t10437 Gouin Boulevard West, Rox-boro.\t05\t11\t73 ADVERTISING PLUS LTD.\t\t18\t01\t74 PUBLICITE PLUS LTEE.\t\t\t\t \tLongueuil.\t22\t02\t74 LA BARRE BOO INN LTD.\t\t\t\t \t\t27\t12\t73 \t2795, Bates, Montréal.\t06\t02\t74 LES AUTOBUS FLEURENT ET FILS INC.\tMont-Tremblant.\t08\t01\t74 \tBeaumont.\t08\t11\t73 BLOUIN A VERDON INC.\t110, rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire.\t27\t12\t73 \t610, boulevard Walberg, Dolbeau.\t20\t12\t73 \t780, rue St-Augustin, Québec.\t18\t01\t74 \t4332 Amos Street, Montreal.\t28\t01\t74 DECOR BREUER LTEE.\t\t\t\t BULLARD, HOFFMAN & ASSOCIATES INSURANCE\t15 Commercial Centre, Roxboro.\t17\t12\t73 AGENCY INC.AGENCE D'ASSURANCE BULLARD, HOFFMAN A ASSOCIES INC.CABLEX INC.CAMPING LAC LEMOYNE INC.CARLETON MANUFACTURERS (1974) LTD.MANUFACTURE CARLETON (1974) LTEE CITADEL ENTERPRISES LTD.ENTREPRISES CITADELLE LTEE COFFRAGE INTERNATIONAL INC.INTERNATIONAL FORM WORK INC.LES CONGELES RAYON-SOLEIL LTEE.CONSTRUCTION CLANCO LTEE.CONSTRUCTION R.LAPOINTE INC.R.LAPOINTE CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION SPIRAL LTEE.SPIRAL CONSTRUCTION LTD.465, rue Dessureault, Cap-de-la- 21 11 73 Madeleine.Dubuisson.27 12 73 660 Alexis Nihon, SaintrLaurent.25 01 74 Montreal.21 08 73 Montréal.II 12 73 65, Laval, Kénogami.19 12 73 228, rue Lamoureux, Sainte-Julie.03 01 74 Ile-Perrot.18 01 74 56, rue Charlotte, Sorel.07 01 74 21 IS QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971, Vol.106, No.11 Nom / Mime Siège social / Head Office Incorporation Date LA CORPORATION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS & DOMESTIQUES MONTREAL MONTREAL FOREIGN & DOMESTIC INVESTMENTS CORP.COUTU PETROLEUM INC.LES PETROLES COUTU INC.DEBOSSAGE ET PEINTURE LAMOUREUX, GROLEAU LTEE DECORATIONS LAZARE ROSS INC.ANTOINE DIONNE de Papineau, et retour, de la façon suivante: Taux en vigueur: $0.40 par jour par personne.Taux proposés: $0.60 par jour par personne.La requérante demande à la Commission des transports d'être autorisée à donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : Transport de passagers à l'occasion de voyages à charte-partie pour fins éducation-nelles, religieuses, sportives, touristiques et récréatives pour des personnes normales et occasionnellement d'infirmes originant dans un rayon de 20 milles de Beloeil, St-Hilaire et Otterburn Park à destination de tout point situé dans la Province.La requérante demande l'autorisation de louer à long terme un camion tracteur dont la description apparaît au contrat de location de A.C.E.Leasing Ltd.Ce contrat de location se termine le 4 décembre 1975.La requérante demande l'autorisation de louer à long terme un camion tracteur dont la description apparaît au contrat de location de A.C.E.Leasing Ltd.Ce contrat de location se termine le 31 janvier 1976.Demande à la Commission de changer le numéro de série 3724243-003 d'une remorque Can Car 1972 pour se lire 3724274-001.Rôle M-1219 2479-A-(D.2) GASTON ROCH, 250, Westgate, Rosemere, (Terrebonne), P.Que.Rôle M-1220 3024-A D-l LES AUTOBUS BROMONT INC., 509, rue Denison, R.R.3 Granby, P.Q.Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport des employés du * Hillsdale Golf & Country Club Inc.» situé à Ste-Thé-rèse Ouest, pour la saison estivale 1974, avec trajet suivant: « Centre d'Achat Rosemere - Grande Côte - Montée Sanche - Blainville Est - Boul.Labelle - rue Notre-Dame - Montée Ste-Marianne - Club de Golf (Ste-Thérèse Ouest).» Condition et restriction: Ce service sera donné sept jours par semaine et ce à trois départs le matin et trois départs le soir.Cession de propriété du système de transport.(Vente d'actions) Le requérant demande d'autoriser le transfert des actions détenues auparavant par Monsieur René Borduas de la compagnie Les Autobus Bromont inc., pour 99 actions à Monsieur Yvon Messier lui permettant ainsi d'obtenir un total de 971 actions du capital-actions de la compagnie Les Autobus Bromont Inc.et pour 97 i actions à Autobus St-Hubert Inc., corporation légalement cons- The applicant requests an increase in his rates applicable for the transportation of the employees of Hand Chemical, in Papineau, from their homes in Papineauville to the premises of said Company and return: Rate in effect: $0.40 per day per person.Proposed rate: $0.60 per day per person.The applicant requests the 1 ransport Commission to authorize it to provide the following service: Class of permit : Bus service.Sen-ice: Transportation of passengers, i.e.normal persons and, on occasion, physically-handicapped persons, on chartered trips conducted for educational, religious, sports, touristic and recreational purposes, from points within a radius of 20 miles from Beloeil, St.Hilaire and Otterburn Park to any point located in the Province of Québec.The applicant requests authorization to lease, on a long-term basis, a tractor truck described in the lease from A.C.E.Leasing Ltd.This lease expires on September 4th, 1975.The applicant requests authorization to lease, on a long-term basis, a tractor truck described in the lease, from A.C.E.Leasing Ltd.This lease expires on January 31st.1976.The applicant requests the Commission to modify the serial number of a 1972 Can Car trailer, which presently reads 3724243-003 to read henceforth as follows 3724274-001.The applicant requests the Transport Commission to authorize it to provide the following service : Class of permit: Bus service.Service: Transportation of the employees of Hillsdale Golf & Country Club Inc.located in Ste.Thérèse-West, during the 1974 summer season, according to the following itinerary: Rosemere Shopping Centre, Grande Côte, Montée Sanche, Blainville East, Labelle Blvd., Notre-Dame Street, Montée Ste.Marianne, Golf Club (Ste.Thérèse-West).Condition and restriction: This service will be provided seven days a week and will include three departures in the morning and three departures at night.Transfer of ownership of a transportation sen'ice.(Sale of shares) The applicant requests authorization to transfer the shares previously held by Mr.René Borduas of Les Autobus Bromont Inc., namely 99 shares, to Mr.Yvon Messier in order to enable him to hold a total of 971 shares of the share capital of Les Autobus Bromont Inc., and 971 shares to Autobus St-Hubert Inc., a corporation legally incorporated and whose directors are: Maurice 2134 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971,, Vol.106, No.11 Rôle M-1221 1719-A-(D.1) LEOPOLD LETENDRE, Mont-Tremblant, (Terrebonne), P.Que., (Requérant vendeur), JEAN-GUY MARIER, St-Jovite, (Terrebonne) P.Que.(Requérant acquéreur).tituée dont les administrateurs sont Maurice Brais, président, Jean-Pierre Brais, secrétaire.M.Maurice Brais, Président.200 M.Jean-Pierre Brais, Secrétaire-trésorier.275 M.Réal Brais, 2e Vice-Président.150 M.Rolland Brais, 1 er Vice-Président.175 Total: 800 Cession de propriété du système de transport (vente).Monsieur Leopold Letendre demande l'autorisation de céder à monsieur Jean-Guy Marier de St-Jovite (Terrebonne) P.Que.la propriété du système de transport suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service No 1 : Transport des fidèles et des skieurs dans un rayon de dix (10) milles du Mont-Tremblant.Parcours à suivre: Route comprise dans un rayon de dix (10) milles de Mont-Tremblant.Terminus: Mont-Tremblant: Magasin général.Conditions et restrictions: 1.Ordinaires; 2.Le village de St-Jovite ne devra pas être compris dans le rayon de dix (10) milles du Mont-Tremblant; 3.Le détenteur ne devra effectuer le transport d'aucun voyageur du village de St-Jovite; 4.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou a charte-partie.2.Classe de permis: Service d'autobus.Service: Le détenteur pourra effectuer le transport, sur demande, et à tant par tête, de skieurs qui voudraient voyager entre le Lac Ouimet (Hôtel Bellevue) et le Mont-Blanc situé entre St-Jovite et St-Faustin, à environ trois-quarts (3/4) de mille de la route No U.Parcours à suivre: Route régionale: du Mont-Tremblant (Hôtel Bellevue), à St-Jovite.Route No 11 : de St-Jovite à l'intersection de la route No 11 et de la route conduisant au Mont-Tremblant.Route régionale: de l'intersection de la route No 11 et de la route conduisant au Mont-Tremblant, au Mont-Blanc.Terminus: Mont-Tremblant: Hôtel Bellevue.Mont-Blanc.Conditions et restrictions: 1.Ordinaires; 2.Ce service est à l'usage exclusif des skieurs qui désirent voyager entre l'Hôtel Bellevue et le Mont-Blanc; 3.Ce permis ne confère aucun des privilèges de l'Ordonnance générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Brais, president, and Jean-Pierre Brais.secretary.Mr.Maurice Brais, President.200 Mr.Jean-Pierre Brais, Secretary-Treasurer.275 Mr.Réal Brais, 2nd Vice-President.150 Mr.Rolland Brais, 1st Vice-President.175 Total: 800 Transfer of ownership of a transport service (sale).Mr.Leopold Letendre requests authorization to transfer to Mr.Jean-Guy Marier of St.Jovite.County of Terrebonne.P.Q., the ownership of the following transport service: Class of permit: Bus service.Service No.1: Transportation of church attendants and skiers within a radius of ten (10) miles from Mont-Tremblant.Route: All the roads comprised within a radius of ten (10) miles from Mont-Tremblant.Terminal: Mont-Tremblant: General store.Conditions and restrictions: 1.Usual; 2.The village of St.Jovite shall not be included within the radius of ten (10) miles from Mont-Tremblant; 3.The permit-holder is not authorized to transport any passengers of the village of St.Jovite; 4.This permit does not confer any of the privileges granted by General Order No.17 respecting special or chartered trips.2.Class of permit: Bus service.Service: The permit-holder may provide a transportation service on request, at a fixed price per person, for the skiers wishing to travel between Lake Ouimet (Bellevue Hotel) and Mont-Blanc located between St.Jovite and St.Faustin, about three-quarters (%) of a mile from Highway No.11.Itinerary: Regional road: from Mont-Tremblant (Bellevue Hotel) to St.Jovite.Highway No.11: From St.Jovite to the intersection of Highway No.11 with the road leadSng to Mont-Tremblant.Regional road: From the intersection of Highway No.11 and the road leading to Mont-Tremblant and Mont-Blanc.Terminal : Mont-Tremblant: Bellevue Hotel.Mont-Blanc.Conditions and restrictions: 1.Usual; 2.This service is reserved exclusively for the transportation of skiers wishing to travel between Bellevue Hotel and Moot-Blanc.3.This permis does not confer any of the privileges granted by General Order No.17 respecting special and chartered trips. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° U 2135 Rôle M-1222 23666-VM D-l LAKESHORE INTERNATIONAL MOVERS & WAREHOUSING LTD., 2760, Sheffield Road, Ottawa.Ontario K1B 3V9.applicant Adresse au Québec: 115 Hymus Blvd.Pointe Claire, Dorval 730, P.Que.La requérante demande à la Commission l'autorisation d'effectuer les services de transport suivant: Transport de ménage au sens de l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, par fourgons conçus pour le transport des ménages et munis des dispositifs nécessaires, lesdits sont exclusivement utilisés pour le transport des ménages.a-1) Transport restreint - longue distance - route restreinte - a~l) De tous les points situés dans la province de Québec à la frontière Nouveau-Brunswick-Québec et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: les provinces canadiennes situées à l'est de la province de Québec.a-S) Transport restreint - longue distance - route restreinte - a-S) De tous les points situés dans la province de Québec à la frontière Etats-Unis-Québec et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: des points situés aux Etats-Unis.a-3) Transport restreint - longue distance - route restreinte - a-3) De tous les points situés dans laR province de Québec à la frontière Québec-Ontario et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: les provinces canadiennes situées à l'ouest de la province de Québec.a-4) Transport restreint - longue distance - route restreinte - a-4) D'une frontière à l'autre frontière, dans la province de Québec (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: entre toutes les provinces canadiennes sauf le Québec et entre leBdites autres provinces et les Etats-Unis.Restrictions et conditions: 1.Le présent permis ne donne pas le droit d'exploiter un service local entre les différents points situés dans la province de Québec.2.La clause a-3 du présent permis doit être exploitée avec un certificat No X-2040 délivré par le ministère des transports de l'Ontario, soit la Motor Vehicle Branch (division des véhicules automobiles) en date du 22 août 1973 et avec des certificats ou permis devant être délivrés par les autorités y mentionnées; copie de chacun desdits permis doit être transmise à la Commission des transports du Québec.3.Les clauses a-1, a-S et a-4 doivent être exploitées avec des certificats ou permis délivrés par les autorités ayant juridiction dans les localités d'origine ou de destination des biens transportés; copie desdits permis doit être transmise à la Commission des transports du Québec.4.Le service de transport autorisé par les clauses a-1, a-S, a-3 et a-4 du présent permis sur les routes de la province de Québec sera effectué au moyen de camions spécialement conçus et équipés pour le transport de ménage et d'ameublement usagé au sens de l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage.5.Le détenteur du permis devra fixer sur les véhicules transportant les ménages des plaques, accordées en vertu d'accords de réciprocité, délivrées par la Commission des transporta du Québec.The applicant has petitioned the Commission, in order to obtain the right to give the following transportation services: Transportation of household goods as defined by article 51 of the General Order on Trucking; in special household goods moving vans equipped with the necessary accessories and used exclusively for the transportation of household goods.(a-/j Restricted trucking - long distance - restricted route - (o-l) From all Idealities situated in the Province of Québec to the New-Brunswick-Québec border, and return (via irregular routes and all ports of entry).Destination: Provinces of Canada, East of the Province of Québec.(a-S) Restricted trucking - long distance -restricted route - (a-S) From all localities situated in the Province of Québec to the United States-Quebec border and return (via irregular routes and all ports of entry).Destination: localities in the United States.(a-3) Restricted trucking - long distance -restricted route - (a-3) From all localities situated in the Province of Québec to the Ontario* Que bee border and return (via irregular routes and all ports of entry).Destination: Provinces of Canada, West of the Province of Québec.(a-4) Restricted trucking - long distance -restricted route- (a-4) From one border of the Province to another border of the Province (via irregular routes and all ports of entry).Destination: between all Provinces of Canada, except Québec, and between the said other Provinces and the United States.Restrictions and conditions: 1.No local service between points in the Province of Québec is authorized by this permit.2.Clause a-3 of this permit is to be operated in conjunction with a certificate No.X-2040 issued by the Ontario Department of Transport, Motor Vehicle Branch dated August 22, 1973 and also in conjunction with certificates or permits to be issued by other jurisdictions referred to therein and copy of which must be filed with the Québec Transport Commission.3.Clauses a-1, a-2 and a-4 are to be operated in conjunction with certificates or permits issued by the authorities having jurisdiction in the localities at which the goods originate or to which the goods are destined copy of which must be filed with the Québec Transport Commission.4.The transportation authorized by clauses a-1, a-S, a-3 and a-4 of the permit over the roads of the Province of Québec, shall be made in specially designed and equipped household goods moving vans used exclusively for the transportation of household goods and second hand furniture as defined by Article 51 of the General Order on Trucking.5.The permit holder shall have affixed to the vehicles, transporting household goods reciprocity plates of the Québec Transport Commission. 2136 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 6.La Commission devra reconsidérer et modifier ce permis advenant que le détenteur cesse d'agir en tant que voitutier-remorqueur pour le compte de Aero Mayflower Transit Co.Ltd.et de Aero Mayflower Transit Inc.7.En donnant le service autorisé par le présent permis, le détenteur n'est pas autorisé à transporter des meubles et accessoires ou de l'équipement électronique neuf non emballés non plus que les pièces s'y rattachant.8.La requérante devra tenir compte des articles 36 et 39 de la Loi des transports (du Québec), qui stipulent que tout contrat apportant une modification quant au contrôle des services autorisés doit être soumis à l'approbation de la Commission.Transport de meubles et d'accessoires neufs non emballés pour les magasins, bureaux, musées, institutions, hôpitaux et autres établissements, (transport) de tabulatrices, comprenant toutes machines auxiliaires ou pièces essentielles aux opérations de calcul, comprenant les poinçons, les trieurs, les ordinateurs, les vérificateurs, les relieurs, les appareils de reproduction et d'interprétation, les multiplicateurs, les installations de fils, les tableaux de commande et les pièces s'y rattachant.b-t) Transport restreint - longue distance - route restreinte - b-1) De tous points situés dans la province de Québec à la frontière Québec-Nouveau Brunswick et retour (via des itinéraires irré-guliers et tous ports d'entrée).Destination: les provinces canadiennes situées à l'est de le province de Québec.b-S) Transport restreint - longue distance - route restreinte - b-S) De tous points situés dans la province de Québec à la frontière Québec-Etats-Unis et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination : différents points situés aux Etats-Unis.b-S) Transport restreint - longue distance - route restreinte - 6-3) De tous points situés dans la province de Québec à la frontière Québec-Ontario et retour (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: les provinces canadiennes situées à l'ouest de la province de Québec.b-4) Transport restreint - longue distance - route restreinte - b-4) D'une frontière à toute autre frontière de la province de Québec (via des itinéraires irréguliers et tous ports d'entrée).Destination: entre les provinces canadiennes sauf celle du Québec et entre lesdites autres provinces et les Etats-Unis.Restrictions aux clauses 6-7, b-S, 6-3, b-4: 1.Les véhicules utilisés pour le transport de marchandises mentionnées ci-dessus doivent être immatriculés par les autorités provinciales ainsi qu'auprès de la Commission; le transport sera effectué au moyen de véhicules dont la plate-forme peut être abaissée ou par tous autres véhicules de déménagement spéciaux, généralement utilisés pour le transport de ménages.2.Les restrictions générales rattachées au permis détenu par la requérante et applicables au transport des ménages s'appliqueront également pour les services ci-dessus.6.This permit shall be subject to reconsideration and revision by the Commission in the event of the permit holder ceasing to be hauling agent of Aero Mayflower Transit Co.Ltd.and Aero Mayflower Transit Inc.7.The transportation of new uncrated furniture and fixtures and electronic equipment and parts therefor in strictly prohibited when giving a service in virtue of this permit.8.The attention of the applicant is drawn to Article 36 and 39 of the Québec Transport Act, which requires that any contract effecting a change in control of the authorized services must receive the approval of the Commission.Transportation of new uncrated furniture and fixtures of stores; offices, museums, institutions, hospitals or other establishments, tabulating machines including such auxiliary machines or component parts as are necessary to the performance of a complete, tabulating process, including punches, sorters, computers, verifiers, collators, reproducers, interpreters, multipliers, wiring units and control panels and spare parts therefor.(6-/) Restricted trucking - long distance -restricted route - (b-l) From all localities situated in the Province of Québec to the New-Brunswick-Québec border, and return (via irregular routes and all ports of entry).Destination: Provinces of Canada, East of the Province of Québec.(b-S) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-2) From all localities situated in the Province of Québec to the United States-Quebec border and return (via irregular routes and all ports of entrv).Destination: localities of the United States.(6-3) Restricted trucking - long distance -restricted route - (b-S) From all localities situated in the Province of Québec to the Ontario-Québec border, and return (via irregular routes and all ports of entry).Destination: Provinces of Canada, West of the Province of Québec.(b-4) Restricted trucking - long distance -restricted route - (b-4) From one border of the Province to another border of the Province (via irregular routes and all ports of entrv).Destination: between all provinces of Canada, except Québec, and between the said other Provinces and United States.Restriction, to clauses b-1, b-S, b-S, b-4 : 1.Vehicles utilized in transporting merchandise above mentioned must be registered with the Province and with the Commission and such vehicles shall be of the drop frame or other specialized type moving vans as normally utilized for the transportation of household goods.2.The general restrictions applicable to the permit held by the applicant covering the transportation of household goods shall equally apply to the above services. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2137 Rôle M-1223 108-DYV D-2 AVIS TRANSPORT OF CANADA LTD., 750.Laurentian Boulevard, Montréal 379, P.Q.Rôle M-1224 86-DY et 108-DYV D-3 AVIS TRANSPORT OF CANADA LTD.750, Laurentian Boulevard, Montréal 379, P.Q.Rôle M-1225 D-l TF 21992-V ARNOLD BROS.TRANSPORT LTD., 212, avenue Bloomfield.Montréal, P.Q.H2V 3R4.Rôle M-1226 D-l TF 8046-V RAMSAY'S MOVING & CARTAGE LTD., 5623 Rosedale, Côte St-Luc, Montréal.P.Q.Rôle M-1227 D-l-TF 2114 SERVICE D'EXPÉDITION MÉTROPOLITAIN INC., 276 rue St-Jacques-ouest, Montréal, P.Que.Rôle M-1228 D-l TF8I9-V RAOUL MARTINEAU INC., 316, 12e Avenue-sud, Sherbrooke, P.Q.Droits additionnels: La requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à exploiter une filiale supplémentaire de location à: 6974.avenue Broadway.Montréal Est.Garage de Gulf Oil Canada Limited: pour donner le service de location suivant: Service 3: Location à court terme de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la route.Service 4: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorque.1*).Droits additionnels: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, l'autorisation d'ajouter à ses services de location de véhicules les droits de location additionnels suivants: Service 1: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade.Service 2: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons).Service 3: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la route.Service 4: Location à long terme (une année et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) au sens du Code de la route.Les quatre services pour être donnés aux nouvelles succursales suivantes: Aéroport de Matagami, Territoire Baie James: Aéroport de la Grande Rivière (L.G.2), Territoire Baie James: Ville Radisson à un endroit à déterminer avec la Société de développement de la Baie James.La requérante demande l'annulation du tarif No 11 pour qu'il soit remplacé par le tarif No 12 daté du 1er février 1974 et effectué à la date de la décision de la Commission des transports du Québec.Le tarif No 12 égale une augmentation de 8% sur le tarif No 11.Demande d'augmentation d'environ 21% sur les taux antérieurs.Demandons: augmentation approximative de 10% sur nos taux actuels.Demande d'augmentation de taux pour le transport local de ménages, d'effets personnels et le transport général d'environ 25% sur nos taux actuels.Additional rights: The applicant is asking the Québec Transport Commission authorization to set up one additional Leasing branch at: 6974, Broadway Avenue, Montreal East, Garage of Gulf Oil Canada Limited: to give the following leasing services: Service 3: Short term Leasing of Commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) as defined in the Highway Code.Service 4 : Leasing of Commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) on a long term basis (one year or over).Additional rights: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to add the following additional leasing rights to its present vehicle-leasing services: Service 1 : Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than one year).Service 2: Leasing of pleasure vehicles (automobiles and station-wagons) on a long-term basis (one year or more).Service 3: Leasing, on a short-term basis, (less than one year), of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers), within the meaning of the Highway Code.Service 4: Leasing on a long-term basis (one year or more) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) within the meaning of the Highway Code.These four services shall be operated at the new branches which are the following: Matagami Airport, James Bay Territory: Grande Rivière Airport (L.G.2), James Bay Territory: Town of Radisson at a place to be agreed upon with the James Bay Development Corporation.The applicant requests that the tariff No.11 be cancelled and replaced by tariff No 12 dated February 1st 1974, the foregoing to take effect on the date of the decision of the Québec Transport Commission.Tariff No.12 represents an 8% increase on tariff No.11.Request increase of approximately 21% over previous rates.Request for an increase of approximately 10% on our present rates.Application for an increase of approximately 25% on our present rates for the local transportation of household goods, personal lielongings and for general trucking. 2138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- 106, No.11 Rôle M-1229 D-l TF 11009-V MORGAN STORAGE AND MOVING LTD., 560, Orly Avenue, Dorval, P.Q.Rôle M-1230 M D-2 TF 4810-V ROY TRANSPORT (Gerald Roy.Prop.).62, rue Nord.Waterloo.P.Q.Role M-1231 D-l-TF 35-N LA TRAVERSE RIVIÈRE-DU-LOUP.St-Siméon Ltée.1155 boul.Dorchester ouest.Montréal.P.Que.Rôle M-1232 D-l-TF 17373-V IMPERIAL ROADWAYS LTD.484 McPhillips Street.Winnipeg.Man.R2X 2G8 Classe A: Augmentation d'environ 12% des taux déposés antérieurement à la Commission des transports du Québec.Voir annexes E et F.La requérante demande l'autorisation d'augmenter ses tarifs d'environ 8% pour toutes les clauses de son permis.(Voir feuilles attachées à la copie No 7).Class A: Rate increase of approximately 12% on moving rates presently on file with the Quebec Transportation Commission.See appendix E and F.The applicant requests authorization to increase its tariffs by approximately 8% for all the clauses of its permit.(See sheets attached to copy No.7).La requérante demande à la Commission d'être autorisée à modifier des tarifs comme suit: Anciens taux / Prexiou* rate* The applicant requests the Commission to authorize it to modify its tariffs as follows: Tarif réduit Reduced Tariff Tarif général 20 juin au 10 sept.General Tariff June 20 to Sept.10 Adultes / Adult* Enfants (Agés de 6 ans et moins de 12 ans) / Children (aged 6 to IS years) Automobiles/ Automobiles Autobus / Bus S 2.25 simple / sinale fare ?2.50 simple / single fare 1.10 simple Isinole fare 5.50 simple / single fare 20.00 simple / single fare Nouveaux taux / New rales Tarif réduit 1.20 simple / single fare 6.00 simple / single fare 22.00 simple / single fare Reduced Tariff Adultes / Adults S 2.50 simple / single fare Enfants (ages de 6 ans et moins de 12 ans) / Children (aged 6 to It years) 1,20 simple / single fare Automobiles / Automobiles 6.00 simple / single fare Autobus / Bus 22.00 simple / tingle fare Pour information concernant les taux pour bicyclettes, motocyclettes, remorques et camions de toutes catégories, veuillez consulter la liste détaillée des nouveaux taux déposée à la Commission des transports du Québec.Supplément No 1 au tarif No 10-A entre le Québec et l'Ouest du Canada.1.8auf stipulation contraire les taux publiés & la section 1 du présent tarif seront augmentés de la façon suivante: (A) Tous les chargements à destination du Manitoba - augmentation de 8% de la Saskatchewan - augmentation de 7% de l'Alberta - augmentation de 6% de la Colombie Britannique - augmentation de 6% Remarque: Les numéro» tarifaires (items) suivants ne sont pas sujets a l'augmentation: Nos 410, 850 (le taux applicable à un chargement do 40,000 lbs seulement) 1060.1450, 2170 (Montréal a Calgary, Edmonton, Lethbridge et Vancouver seulement).Exception : Les numéros tarifaires (items) suivants sont augmentés comme suit: Item 840 - 4% Item 2350 340 min.20,000 lbs.278 min.30.000 lbs.263 min.40.000 lbs.Tarif général 16 juin au 7 sept.General Tariff June 16 to Sept.7 S 2.75 simple / single fare 1.50 simple / single fare 6.50 simple / single fare 24.00 simple / single fare For further information concerning the rates for bicycles, motorcycles, trailers and trucks of all categories, please refer to delaited lists of the new rates filed with the Québec Transport Commission.Supplement No.1 to commodity tariff No.10-A between Québec and Western Canada.1.Except as otherwise provided, all rates published in section 1 of this tariff will be increased by the following: (A) All weights to Manitoba - increase 8% to Saskatchevan - 7% to Alberta - increase 6% to British Columbia - increase 6% Note: The following items as listed are not subject to increase: Item 410, 850 (40,000 lbs rate only), 1060, 1450, 2170 (Montreal to Calgary, Edmonton, Lethbridge, and Vancouver only).Exception : The following item are increased as listed: Item.840 - 4% Item 2350 - 340 min.20.000 lbs.278 min.30,000 lbs.263 min.40,000 lbs. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2139 Rôle M-1233 D-l-TF 564-V GAUDETTE TRANSPORT ENRC, 10 Chemin St-Jean-Baptiste, Ste-Madeleine, P.Que.JOH ISO Demande d'augmentation de taux d'environ 20% du tarif No 4.Application for an increase in rates of approximately 20% in tariff No.4.Rôle M-1234 M D-l TF 838-DY AUTO HIRE (CANADA) LTD., 7401, Boul.Newman, Lasalle, P.Q.H8N 1X4 La requérante demande à la Commission, la permission d'augmenter ses tarifs pour la location de véhicules de promenade à court terme.The applicant requests the Commission to authorize it to increase its rates for the leasing of pleasure vehicles.Anciens taux / Previous rates Jour Semaine Daily Weekly Week-end Week-end Modèle / Model Chevy II, Nova, Duster, Valiant Chevelle Torino, Satellite Impala, Fury, Galaxie Impala, Fury, Galaxie (air climatisé / with, air conditioning) Familiale / Station wagon \u2022 Taux de location ne comprennent pas la taxe de vente du Québec / The leasing rates do not cover the Québec sales tax.Nouveaux taux / Areio rates $ 7.00\t845.00\t817.50 7t mille / mile\t7i mille / m tie\t7é m Ule / mile 8.00\t50.00\t18.50 8^ mille / mite\tSt mille / mile\t8t mille / mile 9.00\t55.00\t18.50 9é mille / mile\t9^ mille / mile\t9^ mille / mt'le 10.00\t60.00\t19.50 10e mille / mile\t1 (if mille / mile\tlOi mille / mile 13.00\t85.00\t lié mille / mile\t111 mille / mile\t 13.00\t85.00\t 10i mille/mile\tÏOi mille / mils\t \tHeure\tJour\tSemaine\tWeek-end \tPer hour\tDaily\tWeekly\tWeek-end Modèle / Model\t\t\t\t Pinto, Vega, Astre\ti 3.00\t8 14.00\t8 84.00\tS 28.00 Maverick, Duster.Valiant\t4.00\t15.00\t90.00\t30.00 Satellite, Lemans, Chevelle\t4.00\t16.00\t96.00\t32.00 Galaxie 500, Impala, Catalina\t4.00\t17.00\t102.00\t34.00 Grand Torino Cutlass, Monte Carlo\t4.00\t18.00\t108.00\t36.00 Fury III (air climatisé) / (with air\t\t\t\t conditioning)\t5.00\t19.00\t114.00\t38.00 Familiale (9 passagers) / Station wagon\t\t\t\t (9-passengers)\t5.00\t20.00\t120.00\t40.00 Chrysler / Chrysler\t5.00\t22.00\t132.00\t44.00 Familiale (air climatisé) / Station-wa-\t\t\t\t gon (with air conditioning)\t5.00\t22.00\t132.00\t44.00 Rôle M-1235 M D-l TF 730 DY-V ROCLAR LEASING LIMITÉE, 400, rue Norman, Ville St-Pierre, P.Q.Rôle M-1236 M-24001 D-l L'UNION DES PROPRIÉTAIRES DE TAXIS DE GRANBY, Granby, (Shefford), P.Que.Rôle M-1237 M D-l TF 5571-V FERNAND CRÊPEAU, Ste-Brigitte Des Saults, P.Q.Demande autorisation de transport à court terme: (Tracteur-remorque) 82.00 par jour d'augmentation.jusqu'à 48,000 lbs $.04 du mille en sus de 48,000 lbs $.03 du mille La requérante demande de fixer à $0.70 le tarif initial au départ pour les propriétaires de véhicule-taxi opérant dans l'agglomération de Granby.Je demande à la Commission l'autorisation d'augmenter mes taux de transport de 16% pour Québec et environ 40% pour Montréal.Application for an authorization for short-term transport: (Tractor-trailer) $2.00 per day increase up to 48,000 lbs.$.04 per mile increase over 48,000 lbs.8.03 per mile The applicant requests that the departure tariff be fixed at 80.70 for taxi-vehicle owners operating in the Conglomeration of Granby.I request from the Commission the authorization to increase my transport rates as follows: 16% for Québec City and approximately 40% for Montreal. 2140 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Rôle M-1238 M D-l TF 11717-V YVON LAROCQUE TRANSPORT LTÉE., 7000, rue Pullman, Montréal, P.Q.Rôle M-1239 M D-l TF 1772-V ROBERT TRANSPORT LTÊE., 130, 1ère Avenue.Rougemont, P.Q.Rôle M-1240 M D-l TF 21347-V ROBERT TRANSPORT QUÉBEC LTÉE., 103.1ère Avenue.Rougemont.P.Q.Rôle M-1241 M D-23-TF BT-3 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS-TARIFF BUREAU ASSOCIATION 4180 Dundas St., West.Toronto, Ontario M8X 1X8 Rôle M-1242 M D-22-TF BT-3 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS-TARIFF BUREAU ASSOCIATION 4180 Dundas St.West.Toronto Ont.M8X 1X8 Rôle M-1243 M D-24-TF 40003 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASSOCIATION 4180 Dundas St., Toronto.Ont.M8X 1X8.Rôle M-1244 M D-25-TF 40003 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASSOCIATION, 4180 Dundas St., W., Toronto, Ont.M8X 1X8 Rôle M-1245 M D-26-TF 40003 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASSOCIATION 4180 Dundas St.West.Toronto, Ont., M8X 1X8 Modification des taux horaires des camions et tracteurs majoration $0.25 relative à l'ordonnance 4560.Demandons augmentation de 10% sur nos taux antérieurs.Demandons augmentation de 10% environ sur nos taux antérieurs.Tarif No 156-C, MF-I.C.C.No 173 \u2014 Canada Ktuts-Unis: Le supplément No 2 (Table de conversion) indique une augmentation de 9.6% de tous les taux de transport et expire le 31 janvier 1975.Le supplément No 3 (expire le 15 mars 1974) augmente de 2% tous les taux de transport modifiés ou émis antérieurement ou subséquemment à la mise en vigueur de ce supplément, afin de compenser toute majoration des coûts du carburant.Le tarif No 155-A MF-I.C.C.No 172 \u2014 Canada Etats-Unis: Supplément No 1 (Table de conversion) indique une augmentation de 9.6% de tous les taux de transport et expire le 31 janvier 1975.Le supplément No 3 (expire le 15 mars 1974) augmente de 2% tous les taux de transport modifiés ou émis antérieurement ou subséquemment à la mise en vigueur de ce supplément, afin de compenser toute majoration des coûts du carburant.Le .supplément N 3 :iu tarif No 163 B.MF-I.C.C No 170 indique des réductions aux sections II et III des taux de transport de cargaisons en provenance ou à destination de certaines localités des Etats-Unis; majorations h la section IV des taux de transport.Supplément No 4 au tarif No 153-B, MF-I.C.C.No 170 augmente de 2% les taux de transport afin de compenser toute majoration des coûts du carburant.Supplément No 12 au tarif No 68, MF-I.C.C 96 augmente de 2% les taux de transport pour compenser toute majoration des coûts du carburant.Le supplément No 23 au tarif No 64, MF-I.C.C.64, augmente de 2% les taux de transport pour compenser toute majoration des coûts du carburant.Modification of hourly rates applying to trucks and tractors; a $0.25 increase in conformity with Order 4560.We request a 10% increase on our former rates.We request an increase of approximately 10% on our former rates.Tariff No.156-C.MF-I.C.C No.173 \u2014 Canada United States: Supplement No.2 (Conversion chart) reflects 9.6% increase in all transportation rates and expires January 31, 1975.Supplement No.3 (expires with March 15, 1974) increases all transportation rates as amended or issued prior or subsequent to this supplement by 2% to offset increases in fuel costs.Tariff No.155-A MF-I.C.C.No.172 \u2014 Canada United States: Supplement No.1 (Conversion chart) reflects 9.6% increase in all tansportation rates and expires January 31.1975, Supplement No.3 (Expires March 15, 1974) increases all transportation rates as amended or issued prior or subsequent to this supplement by 2% to offset increases in fuel costs.Supplement No.3 to Tariff No.153-B.MF-I.C.C.No.170 reflecting reductions in Sections II and III Transportation rates to and Irom certain named points in the United States; increases Section IV Transportation rates.Supplement No.4 to Tariff No.153-B.MF-I.C.C.No.170 increasing transportation rates by 2% to offset increased fuel costs.Supplement No.12 to Tariff No.68, M.F.-I.C.C.No.96 increases transportation rates by 2% to offset increased fuel costs.Supplement No.23 to Tariff No.64.MF-I.C.C.64, increases transportation rates by 2% to offset increases in fuel costs. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2141 Rôle M-1246 M D-27-TF 40003 CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASSOCIATION, 4180 Dundas St., West.Toronto, Ont.M8X 1X8.Rôle M-1249 M D-7 TF 30006 NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU, INC., P.O.Box 184, Buffalo.N.Y.14221.Membres participants Associated members Rôle M-1250 D-l TF 1234-V BEL-MAR EXPRESS ENRG., 754, 3e rue, Shawinigan, P.Q.Rôle M-1251 D-l TF 4120-V DIXON VAN LINES (MONTREAL) LIMITED., 112A, Leacock Road, Pointe Claire, P.Q.Rôle M-1252 D-2 TF 8191-V CHARBONNEAU TRANSPORT INC., 320 Avenue du Lac, St-Donat, Cté Montcalm, P.Q.JOT 2C0 Rôle M-1253 9659-V D-2 K1NGSWAY TRANSPORTS LIMITED, 10,525, Côte de Liesse Road, Dorval, Ile de Montréal.Le tarif No 148-B MF-I.C.C.No 164, supplément No 22 indiquant des augmentations de taux applicables au supplément intérim de tarif et aux taux de manutention en entrepôt.Le supplément No 23 augmente de 2% les taux de transport pour compenser toute majoration des coûts du carburant.Demande de fixation de tarif.Supplément 14 au Tarif 261-C (Marchandise Générale) Item 930O-B (Réduction).Augmentation de tarif.Le tout représente une augmentation approximative de 20 à 75%.Demande de modification de taux afin d'annuler le tarif No 6 - Montréal et localités situées dans un rayon de 75 milles de ladite ville, le remplaçant par le tarif No 7 en vigueur à compter du 1er mars 1974, comprenant les taux suivants: Horaire normal -Fourgon $7.00 l'heure, chaque homme $8.50 l'heure; heures supplémentaires - Fourgon $7.00 l'heure, chaque homme $12.75 l'heure, aussi le déplacement régulier de machinerie de bureaux, fourgon et 2 hommes - $21.00 l'heure.La requérante demande une augmentation de 15% sur les tarifs déposés pour l'année 1973, et dépose de nouveaux taux amendés à cet effet.La requérante s'est adressée à la Commission afin d'obtenir l'autorisation d'ajouter à son permis les services suivants : 1.Transport restreint - longue distance -route restreinte - remorque-citerne - contrat - 1.De Sherbrooke à Montréal, pour le transport d'oxygène liquide, par remorques-citernes, pour le compte de Canadian Oxygen Limited, Sherbrooke, et retour avec les remorques citernes vides.2.Transport restreint - longue distance -route restreinte - remorque-citerne - contrat - 3.De Sherbrooke à la frontière Québec-Ontario (ports de sortie: Pointe-Fortune et Rivière-Beaudette) pour le transport d'oxygène liquide, par remorques-citernes, pour le compte de Canadian Oxygen Limited, Sherbrooke, et retour avec remorques-citernes vides (Destination: Ottawa, Ontario).Conditions.1.Afin d'effectuer les services décrits aux clauses 1 et 2 ci-dessus, la détentrice devra utiliser les remorques-citernes appartenant à Canadian Oxygen Limited et qui lui sont louées par cette dernière; lesdites remorques-citernes, qui ont été immatriculées dans la province de Québec par l'expéditrice et à de la Régie par Kingsway Transports Limited, seront remorquées au moyen de tracteurs dûment immatriculés dans la province de Québec par ladite détentrice.Tariff No.148-B MF-I.C.C.No.164.supplement No.22 reflecting increases in SIT and Warehouse handling rates.Supplement No.23 increasing transportation rates 2% to offset increased fuel costs.Application for fixation of tariff.Supplement 14 to Tariff 261-C (General Commodities) Item 9300-B (Reduction).Increase in tariff.The whole represents increase of 20 to 75%.an approximate Application for change of rates to cancel tariff No.6 Montreal and points within a 75 mile radius thereof replacing it with tariff No.7 effective March 1, 1974 containing rates as follows: Regular Time - Van $7.00 per hour, each man $8.50 per hour, overtime -Van $7.00 per hour, each man $12.75 per hour, also regular movement of business machines, Van and 2 men $21.00 per hour.The applicant requests a 15% increase on the tariffs filed for the year 1973, and files new rates amended accordingly.The applicant has applied to the Commission, in order to add the following services to its permit: 1.Restricted trucking - long distance -restricted route - tank trailer - contract - 1.From Sherbrooke to Montreal, for the transportation of liquid oxygen, in tank trailer, for the account of Canadian Oxygen Limited, Sherbrooke, and return with empty tank trailers.2.Restricted trucking - long distance -restricted - route - tank trailer - contract - 2.From Sherbrooke to the Québec-Ontario border (ports of exit: Pointe-Fortune and Rivière-Beaudette) for the transportation of liquid oxygen, in tank trailers, for the account of Canadian Oxygen Limited.Sherbrooke, 3nd return with empty tank trailers (Destination: Ottawa, Ontario).Conditions: 1.In order to effect the services described in clauses 1 and 2 above mentioned, the permit holder must utilize the tank trailers owned by and leased to the said permit-holder by Canadian Oxygen Limited, such tank trailers which have to be registered with the Province of Québec by the shipper and with the Board by Kingsway Transports Limited shall be hauled with tractors duly registered in the Province of Québec by the said permit holder. 2142 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 7074.Vol t06, No.11 2.L'autorisation ci-dessus décrite sera valide à condition que la compagnie Canadian Oxygen Limited ait demandé et obtenu de la Commission des transports du Québec, le droit de louer ses remorques-citernes à Kings-way Transports Limited, afin de permettre à celle-ci d'effectuer les services autorisés, pour son compte.(Restrictions générales et conditions (en annexe).Restrictions et conditions générales se rattachant au service ci-dessus mentionné: 1.Conformément aux règlements de la Régie, deux copies des taux particuliers s'appliquant à ce service seront déposés par la détentrice.2.Des polices d'assurance seront maintenues en vigueur pour la durée de cette autorisation, couvrant, pour la remorque appartenant à Canadian Oxygen Limited, les risques tels que la responsabilité civile, les dommages a la cargaison et à la propriété d'autrui.3.Pendant la période au cours de laquelle la remorque sera utilisée par le voiturier-remorqueur, ledit matériel devra porter des plaques d'identification amovibles portant un numéro de série faisant partie de la série attribuée au remorqueur: ces plaques d'identification devront être enlevées par le remorqueur au moment où il rendra le matériel à son propriétaire.Lesdites plaques d'identification devront indiquer, en lettres d'au moins deux pouces de hauteur, que la remor-aue est utilisée dans le cadre du permis de la détentrice.Lesdites plaques devront être apposées de chaque côté de la remorque.4.Le voiturier-remorqueur devra faire inspecter ladite remorque par ses représentants attitrés, qui détermineront si le matériel a été transféré et reçu en bon état de fonctionnement.5.Le voiturier-remorqueur, sur réception de la remorque, en aura la possession et le contrôle exclusifs.Il devra donc en assumer l'entière responsabilité.6.Le voiturier-remorqueur devra fournir son propre chauffeur et son propre matériel pendant la période de temps où ladite remorque sera en sa possession.7.Toute remorque louée par Kings way Transport Limited de Canadian Oxygen Limited peut être tirée par le voiturier-remorqueur pourvu que ladite remorque ait été immatriculée à la Régie, suivant la formule RT-33, qui devra indiquer le nom du propriétaire, le numéro de la plaque d'immatriculation délivrée au propriétaire par les autorités provinciales; la Régie délivrera un certificat d'autorisation de même qu'une plaque RT.8.La plaque « RT \u2022 doit être apposée a ce véhicule à partir du moment où l'opérateur commence le remorquage; elle devra être enlevée au moment où le contrat prendra fin.Le chauffeur du tracteur tirant la remorque devra avoir en sa possession en tout temps le certificat de la Régie indiquant le numéro « RT » accordé à 1 opérateur ainsi que le numéro de la plaque provinciale émise au nom du propriétaire pour ladite remorque.9.Le chauffeur du tracteur tirant la remorque devra avoir en main une photocopie de ce permis pend and la période de temps au cours de laquelle il utilisera cette remorque en vert 11 dudit permis.2.The above mentioned authority shall be valid, provided Canadian Oxygen Limited has applied for and has obtained from the Transport Commission the rieht to lease its tank trailers to Kingsway Transports Limited, in order that it may give the services, as authorized, for its account.(General restrictions and conditions (appended).General restrictions and conditions attached to the above mentioned service: 1.Specific rates are applicable to such service and shall be filed, in duplicate, by the permit holder, in accordance with the regulations of the Board.2.Insurance policies shall be maintained, during the existence of this authority covering public liability, cargo and property damage, with respect to the trailer belonging to Canadian Oxygen Limited.3.Said equipment shall carry removable identification devices, for the period during which the trailer is operated by the operator, bearing a serial number in the operator's own serial; such identification devices shall be removed by the operator when returning possession of the equipment to the owner; the said identification devices shall indicate, in letters not less than two inches in height, that the trailer is being operated under authority of the permit holder and the said identification devices shall be affixed to both sides of the trailer.4.The operator shall cause the said trailer to be inspected by its authorized representatives who shall verify that the equipment has been transferred and accepted in sound operating order and condition.5.The operator, from the moment of reception of the trailer, aforesaid shall have the exclusive possession and control of the trailer, and shall assume the entire responsibility with respect thereto.6.The operator shall operate the said trailer during the time it is in its possession with its own driver and equipment.7.Any trailer leased by Kingsway Transports Limited from Canadian Oxygen Limited, can be hauled by the operator provided the said trailer is registered with the Board, on the form RT-33.which shall show the name of the owner, the plate number of license issued by the Province to the owner, and the Board shall issue a certificate of permit and an \"RT\" plate.8.The \"RT\" plate shall be affixed to such vehicle on the commencement of the haul by the operator, and shall be removed on the termination of the leasing contract.The driver of the tractor hauling the trailer shall have at all times in his possession, the certificate of the Board which shall show the \"RT\" number issued to the operator and the Provincial plate number issued in the name of the owner of the trailer with respect to the trailer.9.A photocopy of this permit shall accompany the driver cf the tractor hauling the trailer during the time that it is being operated in virtue thereof. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2143 Rôle M-1254 3361-A D-l ANDRÉ RENAUD., 43, me Fresnière, St-Benoit, (Mirabel), Comté Deux-Montagnes, P.Q.Rôle M-1255 23543-V D-l ARGOSY SERVICES Nicholas Zizos, opérant sur le nom de: Operating under the name of: 5755 Sir Walter Scott.Apt.105.Montréal, Que.RôleM-1256 22835-V D-l PARC DE MAISONS MOBILES MONT-LAURIER LTÉE, 1220, boul.Paquette, Mont-Laurier, Que.Le requérant détenteur d'un permis de la Commission demande d'être autorisé à opérer les services suivants: Classe de permis: Service d'autobus.Service a) St-Benoit - St-Hermas et Ste-Scholastique (Mirabel) pour le transport des majorettes le lundi de chaque semaine se rendant à Ste-Scholastique, et retour.Service 6) Occasionnellement, voyages à charte-partie de Mirabel à tout point situé dans un rayon de cinquante (50) milles de ladite ville, et retour, pour le compte des majorettes de la ville de Mirabel.Service c) Occasionnellement, voyages à charte-partie originant de Ville Mirabel à tout point situé dans un rayon de cinquante (50) milles de ladite ville, et retour, pour le compte de b Les Fermières de St-Benoit ».Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, les services de transport suivants : a) Transport restreint - service local - contrat- a) Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville, pour le transport de marchandises, pour le compte de: Drew Chemicals Ltd.Neptune International Shipping Ltd.Columbus Ship Suppliers Ltd.Scandia Shipping Agencies Ltd.Ocean Ship Supply Co.Ltd.b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - b) Montréal aux Ports de Contrecoeur.Sorel.T rois-Rivières, Québec, Beauharnois, Port Alfred et Baie Comeau, pour le transport de marchandises, pour le compte de: Drew Chemicals Ltd.Neptune International Shipping Ltd.Columbus Ship Suppliers Ltd.Scandia Shipping Agencies Ltd.Ocean Ship Supply Co.Ltd.Modification de permis (droits additionnels) La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis, les services suivants: 1.Transport restreint - longue distance-territoire - 1.A Mont-Laurier aux points et entre tous les.points situés dans un rayon de 50 milles des limites de ladite ville.2.Transport restreint - longue distance -rayon - 2.De Mont-Laurier et de tous les points situés dans un rayon de 50 milles des limites de ladite ville à tous les points situés dans un rayon de 150 milles des limites de ladite ville, et retour.3.Transport restreint - longue distance-territoire - 3.Entre tous les points situés dans la province de Québec, pourvu que la distance entre ces deux points excède 100 milles.Dans les 3 cas, pour le transport de ménages et ameublements usagés tels que définis à l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage, dans des véhicules spécialement agencés et utilisés à cette fin.The applicant, holder of a permit from the Commission, requests authorization to operate the following services: Permit of class: Bus service.Service (a) St.Benoit - St.Hermas and Ste.Scholastique (Mirabel) for the transportation of majorettes travelling to Ste.Scholastique, round trip, on Monday of each week.Service (b) On occasion, chartered trips from Mirabel to any point located within a radius of fifty (50) miles from said Town, and return, on behalf of the majorettes of the Town of Mirabel.Service (c) On occasion, chartered trips leaving from the Town of Mirabel for any point located within a radius of fifty (50) miles from S3id Town, and return, on behalf of \"Les Fermières de St.Benoit\".New application: The applicant requests from the Commission the authorization to provide, under the prescribed conditions, the following transport services: (a) Restricted trucking - local service -contract - (a) Montreal and all points located over a distance of not more than five miles from the limits of said City, for the transportation of goods, on behalf of: Drew Chemicals Ltd.Neptune International Shipping Ltd.Columbus Ship Suppliers Ltd.Scandia Shipping Agencies Ltd.Ocean Ship Supply Co.Ltd.(b) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (b) From Montreal to the seaports of Contrecoeur, Sorel, Trois-Rivières, Québec, Beauharnois, Port-Alfred and Baie-Comeau, for the transportation of goods, on behalf of: Drew Chemicals Ltd.Neptune International Shipping Ltd.Columbus Ship Suppliers Ltd.Scandia Shipping Agencies Ltd.Ocean Ship Supply Co.Ltd.Modification of permit (additional rights).The applicant requests from the Commission authorization to add of the following services to its permit: 1.Restricted trucking - long distance -territory - 1.In Mont-Laurier to points, and between all points located within a redius of 50 miles from the limits of said City.2.Restricted trucking - long distance -radius - 2.From Mont-Laurier and from all points located within a radius of 50 miles from the limits of said City to all points located within a radius of 150 miles fron the limits of said City, and return.3.Restricted trucking - long distance -territory - 3.Between all points located within the Province of Québec, provided that the distance between any such two points does not exceed 100 miles.In all three cases, for the transportation of used household goods and furniture, as defined in article 51 of the General Order on Trucking, in vehicles specially equipped and utilized for this purpose. 2144 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Rôle M-1257 22835-V D-2 PARC DE MAISONS MOBILES MONT-LAURIER LTÉE, 1239, boulevard Paquette, Mont-Laurier, (Labelle), Que.Rôle M-1258 23584-V D-l PIERRE GOYER, 2815, De Carignan, App.2, Montréal, P.Que.Rôle M-1259 2186-A D-3 HUGUETTE LEBOEUF, 6435, rue Louis-Dupire, Montréal, HIM 1A7, P.Q.Modification de permis (droits additionnels).La partie requérante demande à la Commission d'ajouter à son permis les services suivants: 1.Transport restreint - longue distance -rayon - 1.De Mont-Laurier à toutes les localités situées dans un rayon de 150 milles des limites de ladite ville, et retour, pour le transport de débusqueuses, pour le public en général.2.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 2.De Mont-Laurier et Lac Saguay aux comtés d'Abitibi-Est et Abitibi-Ouest, et Rapides des Joachims et retour, pour le transport de débusqueuses, pour le public en général.Nouvelle demande: La partie requérante demande l'autorisation de la Commission de donner, aux conditions réglementaires, les services de transport suivants: a) Transport restreint - service local -contrat \u2014 a) Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville; Montréal et toutes les localités situées sur une distance ne dépassant pas cinq milles des limites de ladite ville; pour le transport de bois plané, par camion à plate-forme, munie de rouleaux; pour le compte de Hébert Lumber Ltd.b) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - b) De Montréal à toutes les localités situées dans un rayon de 50 milles de ladite ville; pour le transport de bois plané, par camion à plate-forme munie de rouleaux; pour le compte de Hébert Lumber Ltd.Restriction aux clauses a) et b)._ Le service décrit dans les clauses susmentionnées ne sera donné que par un seul véhicule.La requérante demande à la Commission des transport l'autorisation de donner le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'enfants de 3 à 7 ans de leur résidence respective et fréquentant les écoles maternelles suivantes, et retour.Garderie Tante Betty, 2820, boul.Rose-mont, Montréal, P.Q.Centre Gemma Gagliani, 7335, rue Cham-bord, Montréal.P.Q.Au Royaume des Petits, 4550, rue Orléans, Montréal.P.Q.Garderie et Maternelle Gertrude Enr'g., 2523, est rue Jean-Talon, Montréal, P.Q.Garderie Stella Matutina.6055, rue De Lanaudière, Montréal, P.Q.Ecole Maternelle St-Edmond de Canterbury, 6650, 39e Avenue, Rosemont, Montréal, P.Q.Ecole St-Joseph, 4101 rue Bordeaux, Montréal, P.Q.Franceses Cabrini, 6855.rue Cartier, Montréal, P.Q.St-Brendan's 5937, 9e Avenue, Rosemont, Montréal, P.Q.Our Lady of Consolata, 8160, rue Rous-selot, Montréal, P.Q.Studio Annine, Montréal, P.Q.Ce service sera donné durant la période scolaire.Modification of permit (additional rights).The applicant requests the Commission to add the following services to its permit: 1.Restricted trucking - long distance -radius - 1.From Mont-Laurier to any point located within a radius of 150 miles from the limits of said Town, and return, for the transportation of skidders, for the public at large.2.Restricted trucking - long distance -restricted route - 2.From Mont-Laurier and Lake Saguay to the Counties of Abitibi-East and Abitibi-West, and Rapides-des-Joachims and return, for the transportation of skidders, for the public at large.New application: The applicant requests the Commission to authorize it to provide the following transportation service according to the prescribed conditions: (a) Restricted trucking - local service -contract - (a) Montreal and any point located over a distance of not more than five miles from the limits of said City; Montreal and any point located over a distance of not more than five miles from the limits of said City; for the transportation of planed wood, by lowbed truck equipped with rollers; on behalf of Hébert Lumber Ltd.(5) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (6) From Montreal to any point located within a radius of 50 miles from the limits of said City; for the transportation of planed wood, by lowbed truck equipped with rollers; on behalf of Hébert Lumber Ltd.Restrictions to clauses a and 6: The service described in the aforementioned clauses shall be provibed with one vehicle only.The applicant requests the Transport Commission to authorize it to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service : Transportation of children 3 to 7 years of age from their homes to the following kindergartens, which they attend, and return.Garderie Tante Betty, 2820 Rosemont Boulevard, Montreal, P.Q.Centre Gemma Gagliani, 7335 Chambord Street, Montreal, P.Q.Au Royaume des Petits, 4550 Orléans Street, Montreal.P.Q.Garderie et Maternelle Gertrude Enr'g, 2523 Jean-Talon Street East, Montreal, P.Q.Garderie Stella Matutina, 6055 De Lanaudière Street, Montreal, P.Q.Ecole Maternelle St-Edmond de Canterbury, 6650 - 39th Avenue, Rosemont, Montreal, P.Q.Ecole St-Joseph, 4101 Bordeaux Street, Montreal, P.Q.Francesca Cabrini, 6855 Cartier Street, Montreal, P.Q.St-Brendan's.5937-9th Avenue, Rosemont, Montreal, P.Q.Our Lady of Consolata, 8150 Rousselot Street, Montreal, P.Q.Studio Annine, Montreal, P.Q.This service shall be provided during the school year. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2145 Rôle M-1260 1587-V D-l WESTMOUNT MOVING & WAREHOUSING LTD., 61, Hymus Blvd., Pointe-Claire Dorval 730, P.Q.Rôle M-1261 633-DYV D-l SUD LOCATION INC., 320, rue St-Charles Est, Longueuil, P.Q.Rôle M-1262 1124-DY et 796-DYV D-l BORG-WARNER ACCEPTANCE CANADA LTD., 3869, Montée Des Sources, Suite 102, Dollard Des Ormeaux, P.Q.La requérante détentrice d'un permis dont la clause a-6 se lit comme suit: a-6) Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - a-6) Pour le transport de matériel de communication et accessoires exigeant une manutention, un équipement et un matériel d'emballage spéciaux, pour le compte de Northern Electric Company, de Montréal, (Que.) jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (destination ou point d'origine: les localités situées dans la province du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile du Prince Edouard) et retour avec l'emballage, et le matériel et l'équipement utilisés, refusés ou rejetés.Restriction: Le service autorisé par cette clause a-6 devra être opéré conjointement avec les permis émis par la New Brunswick, Motor Carrier Board permis No SX-49 du 17 décembre 1965; la province de la Nouvelle-Ecosse, permis No X-101 daté du 2 octobre 1970 et la province de l'Ile-du-Prince-Edouard, per-mi SX-108 daté du 11 mars 1971.demande que le nom de la province de Terre-Neuve soit ajouté en tant que point de destination ou d'origine, ladite clause devant se lire comme suit: a-6) Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - a-6) Pour le transport de matériel de communication et d'accessoires exigeant une manutention, un équipement et du matériel d'emballage spéciaux, pour le compte de la société Northern Electric Company, de Montréal, (Que.) jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick (destination ou point d'origine: les localités situées dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de lTle-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve) et retour avec l'emballage, et le matériel et l'équipement usagés, refusés ou rejetés.Si la modification est accordée, la requérante sera tenue de fournir à la Commission un certificat de permis complémentaire à être délivré par la province de Terre-Neuve.Modification à la clause: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, d'autoriser le changement de la teneur des services 3 et 4 de son permis pour qu'ils se lisent comme suit : Service 3 : Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs et remorques, à 320, St-Charlea Est, Longueuil.Service 4 : Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs et remorques).Demande de changement d'adresse: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à changer l'adresse de sa place d'affaires pour être à l'avenir située à 6600, Trans-Canada Highway, Pointe-Claire.P.Q., H9R 1C2.The applicant, of which clause a-6 of the permit, reads as follows: a-6) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - a-6) For the transportation of communication equipment and supplies requiring specialized handling and equipment, and packing equipment, for the account of Northern Electric Company, from Montreal, Que., to the Québec-New Brunswick Border (destination of origin : localities in the Provinces of New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island) and return with packing, used, refused or rejected material and equipment.Restriction: The service authorized by said clause a-6 shall be operated in conjunction with the permits issued by the New Brunswick, Motor Carrier Board permit No.SX-49 dated December 17, 1965; the Province of Nova Scotia, permit No.X-101 dated October 2.1970 and the Province of Prince Edward Island, permit No.X-108 dated March 11.1971.requests that the name of the Province of New Foundland be added as a point of destination or origin, such clause to read as follows: a-6) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - a-6) For the transportation of communication equipment and supplies requiring specialized handling and equipment and packing equipment, for the account of Northern Electric Company, from Montreal, Que., to the Quebec-New-Brunswick border (destination or origin: localities in the Province of New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland) and return with packing, used refused or rejected material and equipment.If the modification is granted, the applicant shall be required to file with the Commission, a copy of the complementary permit to be issued by the Province of New Found-land.Modification of clause: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to change the terms and conditions of services 3 and 4 of its permit, to read as follows: Service 3 : Leasing on a short-term basis (less than one year) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) at 320 St.Charles East, Longueuil.Service 4: Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) on a long-term basis (one year or more).Application for a change of address: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to change the address of its place of business to: 6600 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, P.Q., H9R 1C2. 2146 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 107*, Vol.106, No.11 Rôle M-1263 589-DY D-l BELAI R RENTAL SERVICE LTD., 1169, ouest, Ave Bernard.Outremont, P.Q.Rôle M-1264 1174-DY D-l CITÉ LAVAL CARAVANE DIVISION LOCATION ENRC, André Laporte, opérant sous le nom de: operating under the name of: 250, Boul.Ste-Rose Auteuil.Requérant vendeur applicant vendor CITE LAVAL CARAVANE DIVISION LOCATION ENRG., Ovide Paquette, operant sous le nom de: operating under the name of: 5007, Boul Des Laurentides, Auteuil.requérant acquéreur applicant purchaser Rôle M-1265 824-DY D-l LANDRY AUTO LOCATION LTÉE, 103.Boul.Labelle.Ste-Rose, Laval, P.Q.Rôle M-1266 303-DYV D-l LOCATION DE REMORQUES DE VERDUN TRAILER RENTALS ENRG., Rhéaume Duhamel, opérant sous le nom de: operating under the name of: 3500.Avenue Verdun.Verdun, P.Q.Rôle M-1267 855-DY et 379-DYV D-l LES LOCATIONS BOISVERT AUTO LEASING INC., 2, Marie Victorin, Boucherville, Cté Chambly, P.Q.Changement d'adresse d'une succursale de location: La partie requérante qui est autorisée à donner les services de location à court terme de véhicules de promenade aux adresses suivantes: 1169, Ouest Avenue Bernard, Outremont; 4520, Jean Talon Est.Montréal; 4833, Boul.St-Laurent, Montréal; 7340, Ave Mountain Sights.Montréal demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à changer l'adresse de la succursale de 4833, boul.St-Laurent pour être à l'avenir situé à: 6004, Est rue Sherbrooke, Montréal.Transfert de permis et vente de services: Le requérant vendeur demande à la Commission des transports du Québec d'autoriser le transfert de son permis et la vente de ses services de location au requérant acquéreur.Droit additionnel: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à ajouter à son permis le droit fe location additionnel suivant: Service: Location de véhicule de promenade à court-terme (moins d'une année) aux clients durant la réparation de leur automobile, ou sous la garde de la requérante, ou aux clients qui attendent la livraison d'un véhicule neuf.Demande de transfer de permis: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec d'autoriser le transfer de son permis à la compagnie - Locations Trans-Québec Rentals Inc.Yvon Duhamel 1 action ordinaire Dame Sophia Cecohino Duhamel 1 action ordinaire Rhéaume Duhamel 38 actions ordinaires Droit additionnels: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à ajouter à son permis en vigueur, les droits additionnels de location de véhicules suivants: Service 3: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade à 2, Marie Victorin, Boucherville.Service 4: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et livraison (camions, tracteurs et remorques) à 2, Marie Victorin, Boucherville.Change of address of a leasing branch: The applicant, which is authorized to provide the pleasure vehicle-leasing services on a short-term basis at the following addresses: _ 1169 Bernard Avenue West, Outremont; 4520 Jean-Talon East, Montreal; 4833 St.Laurent Blvd., Montreal; 7340 Mountain Sights Ave., Montreal requests the Québec Transport Commission to authorize it to change the address of its branch from 4833 St.Laurent Blvd.to: 6004 Sherbrooke Street East, Montreal.Transfer of permit and sale of services: The applicant-vendor requests the Québec Transport Commission to authorize the transfer of its permit and the sale of its leasing services to the applicant-purchaser.Additional right: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to add the following additional leasing right to its permit: Service: Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than one year) to customers while their automobiles are under repair or in the custody of the applicant, or to customers who are awaiting the delivery of a new vehicle.Application for transfer of permit: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to transfer its permit to - Locations Trans-Québec Rentals Inc.Yvon Duhamel Mrs.Sophia Cecchino Duhamel Rhéaume Duhamel 1 common share 1 common share 38 common shares Additional rights: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to add to its permit in force the following additional automobile-leasing rights: Service 3: Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than one year) at 2 Marie-Victorin, Boucherville.Service 4 : Leasing of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) on a short-term basis (less than one year) at 2 Marie-Victorin, Boucherville. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2147 Rôle M-1268 1288-DY D.l BELISLE CHEVROLET OLDSMOBILE INC.109, boul.Laurin.Buckingham, P.Q.partie requérante applicant Bureau chef, 220, rue Principale 0., Hawkcsbuty, Ontario.Rêle Q-0848 23345-V-D-l JEAN-JACQUES SIMARD.400, Champs Elysées.Chicoutimi, Cté Chicoutimi, tireur hauleway operator et / and CHAM PLAIN SEPT-ÎLES EXPRESS INC.CP.30, St-Hubert, Cté Chambly, tiré carrier requérants conjoints joint applicants R61c Q-0849 22725-V-D-l LUCIEN LEBLANC, 14, rue St-Alphonse, Neufchatel.Québec, tireur haulaway operator et /and CHAMPLAIN SEPT-ÎLES EXPRESS INC.CP.30.St-Hubert, Cté Chambly, tiré carrier requérants conjoints joint applicants Rôle Q-0850 22946-V-D-l RICHARD BOLDUC, 138.boul.du Pont.St-Nicolas, Cté Levis, tireur haulaway operator et / and CHAMPLAIN SEPT-ÎLES EXPRESS INC.CP.30, St-Hubert, Cté Chambly.tiré carrier requérants conjoints joint applicants Rôle Q-0861 Q-201979 ALAIN CÔTÉ, 2565 Alexandra, Québec S.Rôle Q-0852 Q-201971 LOUIS-PHILIPPE ROCHETTE, 1521 Ave.Lamontagne ouest, Val Bélair.Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service: Location a long terme (un an et plus) de véhicules de promenade.New application : The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following vehicle-leasing services: Service: Leasing of pleasure vehicles on a long-term basis (one year or more).Service additionnel: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Jean-Jacques Simard à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Champlain Sept-IIes Express Inc., selon les clauses V.W, X.Y.Z et AA, dudit permis No 406-V.Additional service: Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Jean-Jacques Simard to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Champlain Sept-IIes Express Inc.according to clauses V, W, X, Y, Z and AA of said permit No.406-V.Service additionnel: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Lucien Leblanc à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Champlain Sept-IIes Express Inc.selon les clauses V.W, X, Y, Z et A A dudit permis No 406-V.Additional service: Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize^ Lucien Leblanc to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Champlain Sept-IIes Express Inc., according to clauses V, W, X, Y.Z and AA of said permit No.406-V.Service additionnel: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Richard Bol-duc à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Champlain Sept-IIes Express Inc.selon les clauses V, W, X, Y.Z et AA dudit permis No 406-V.Additional service: Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Richard Bol-duc to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Champlain Sept-IIes Express Inc., according to clauses V, W, X, Y, Z and AA of said permit No.406-V.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Daniel Giroux portant le No Q-201739.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-201739, held by Mr.Daniel Giroux.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Florian Bertrand portant le No Q-201916.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-201916.held by Mr.Florian Bertrand. 2148 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106.No.11 Rôle Q-0853 Q-201970 D-l LUCIEN ROCHETTE, 1021, Déry, Val Bélair.Rôle Q-0864 Q-201961 YVON ROCHETTE, 1021, Déry, Val Bélair, P.Q.Rôle Q-0S55 Q-200917 LÉO CARON, 35, rue Du Moulin, Cté Montmagny Rôle Q-0856 Q-201404 JACQUES NADEAU, 582, - 6e Rue, Québec.Rôle Q-0857 Q-201069 D-4 SOCIÉTÉ DE GESTION BELAIR INC., TROIS-RIVIÈRES RADIO TAXI, 1506, rue Champlain, Trois-Rivières.Rôle Q-0858 Q-201405 D-2 MICHEL LIRETTE, 236, Des Commissaires.No 4, Québec 2.Rôle Q-0860 6190-V-D-l TRANSPORT ST-CLÊMENT LTÉE, rue Principale, St-Clément.Cté de Rivière-du-Loup mise en cause.Rôle Q-0861 23236-V-D-l CORMIER & RENAUD INCORPORÉE, De-du-Havre-Aubert.Ues-de-la-Madeleine, partie requérante applicant.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Florian Bertrand portant le No Q-201916 D-3.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Florian Bertrand portant le No Q-201916.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de Mme Marie-Jeanne Cloutier Casault portant le No Q-201939.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de Mme Marthe Lafrance portant le No Q-200497.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Ernest Bigué portant le No Q-201266.Le requérant demande à la Commission des transports du Québec de lui faire transférer l'attestation de M.Nazaire Lirette portant le No Q-201403.Changement de contrôle dans la compagnie (vente d'actions).Monsieur Thomas Belzile a vendu à Dame Rosalyne Caron-Belzile 201 actions qu'il possède dans la mise en cause.On demande l'autorisation à la Commission de ce faire, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi des transports.Distribution actuelle: Monsieur Thomas Belzile 201 actions Dame Alice Charron 1 action Monsieur Claude Belzile 1 action Nouvelle distribution: Dame Rosalyne Caron-Belzile 201 actions Dame Alice Charron 1 action Monsieur Claude Belzile 1 action Demande de permis.La partie requérante demande: a) d'être autorisée à opérer un service de transport identique à celui accordé le 6 juillet 1972 à Cormier & Renaud Enr.(Donald Renaud et Yves Cormier), soit: Transport général - longue distance - route restreinte - via traversier - De Hàvre-Aubert et de tous points situés sur les Iles-de-la-Madeleine à Souris, Ile-du-Prince-Edouard, via le service de traversier opérant entre Cap-aux-Meules et Souris, pour le transport de marchandises destinées à ou provenant de Souris et Charlottetown, I.P.E.et Moncton, N.B.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-201916 D-3, held by Mr.Florian Bertrand.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.201916, held by Mr.Florian Bertrand.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.201939, held by Mrs.Marie-Jeanne Cloutier Casault.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-200497, held by Mrs.Marthe Lafrance.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-201266, held by Mr.Ernest Bigué.The applicant requests the Québec Transport Commission to transfer in his behalf certificate No.Q-201403, held by Mr.Nazaire Lirette.Change of control in the company (sale of shares).Mr.Thomas Belzile has sold to Mrs.Rosalyne Caron-Belzile 201 shares he holds in the company mise en cause.Authorization to do so is requested from the Commission, pursuant to the provisions of section 39 of the Transport Act.Present allotment: Mr.Thomas Belzile Mrs.Alice Charron Mr.Claude Belzile New allotment: Mrs.Rosalyne Caron-Belzile Mrs.Alice Charron Mr.Claude Belzile 201 shares 1 share 1 share 201 shares 1 Bhare 1 share Application for a permit.The applicant requests : (a) Authorization to operate a permit for a transportation service identical with the one granted on July 6, 1972, to Cormier A Renaud Enr.(Donald Renaud and Yves Cormier) , viz : General trucking - long distance - restricted route - via ferry - From Hàvre-Aubert and all points located on the Magdalen Islands to Souris, Prince Edward Island via the ferry service operating between Cap-aux-Meules and Souris, for the transportation of goods shipped to or originated from Souris and Charlottetown P.E.I, and Moncton, N.B. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1974.106' année.n° 11 2149 Rôle Q-0862 23679-V-D-l BERTRAND BÉDARD, 535, - 4ième Rue, Chibougamau, Cté d'Abitibi-Est.partie-requérante applicant.Rôle Q-0863 23640-V-D-l BOWMASTER, CECIL.Andover, N.B., Place d'affaires au Québec.3600, boul.Hamel, Québec, Que., tireur haulaway operator et / and SPEEDWAY EXPRESS LTD., 20, boul.Marie-Victorin.Boucherville, Que., tiré carrier requérants conjoints joint applicants.Rôle Q-0864 23641-V-D-l FISHER, RICHARD, Stickney, N.B., Place d'affaires au Québec 3600, boul.Hamel.Québec, Que.tireur haulaway operator et/and SPEEDWAY EXPRESS LTD., 20, boul.Marie-Victorin.Boucherville, Que., tiré carrier requérants conjoints joint applicants.Role Q-0865 23639-V-D-l SMITH,ERNEST, Andover, N.B.Place d'affaires au Québec: 3600, boul.Hamel.Québec.Que., tireur haulaway operator et/«nd Droit additionnel : En donnant le service précité, les requérants sont autorisés à utiliser des véhicules réfrigérés.Restriction : Le service ci-dessus est sujet à l'obtention de permis complémentaires à être obtenus des autorités de l'Ile-du-Prince-Edouard et du Nouveau-Brunswick avant le 30 juin 1973.b) d'être autorisée à donner le service suivant: Transport général - longue distance - route restreinte - via traversier - De Hàvre-Aubert et de tous points situés sur les Iles-de-la-Madeleine pour le transport de marchandises destinées à ou provenant de Québec et de Montréal via le service de traversier opérant entre Cap-aux-Meules et Souris.Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - service local -Chibougamau et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour la livraison de commandes d'épicerie, pour le compte du Marché d'Alimentation Provigain.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Cecil Bow-master à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Speedway Express Ltd., (13963-V), selon les clauses a et 6 dudit permis No 13963-V.Additional right : In providing the aforementioned service, the applicants shall be authorized to utilize refrigerated vehicles.Restrictions: The aforementioned service shall be subject to the obtainment of complementary permits to be issued by the authorities of Prince Edward Island and of New Brunswick, prior to June 30, 1973.(b) Authorization to provide the following service: General trucking - long distance - restricted route - via ferry - From Hàvre-Aubert and all points located on the Magdalen Islands for the transportation of goods shipped to or originated from Québec and Montreal via the ferry service operating between Cap-aux-Meulea and Souris.Application for a permit.The applicant requests the following permit: Restricted trucking - local service -Chibougamau and all points located over a distance of not more than 5 miles from the limits of said Town, for the delivery of grocery orders on behalf of Marché d'Alimentation Provigain.New application.Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Cecil Bow-master to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Speedway Express Ltd., (13963-V), according to clauses a and b of said permit No.13963-V.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Richard Fisher à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Speedway Express Ltd., (13963-V).selon les clauses o et b dudit permis No 13963-V.New application.Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Richard Fisher to haul with his duly-registered tractors the trailers of Speedway Express Ltd., (13963-V).according to clauses a and b of said permit No.13963-V.Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Ernest Smith à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Speedway Express Ltd.(13963-V), selon les clauses a et 6 dudit permis No 13963-V.New application.Haulaway transportation - contract -Request is made to authorize Ernest Smith to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Speedway Express Ltd.(13963-V).according to clauses a and b of said permit No.13963-V. 2150 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- 106, No.11 Rôle Q-08S1 D-l TF 2873-V LAMOTHE QUEBEC INC., 209, 9e Rue, Noranda, P.Q.I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » : Rôle Q-0859 3486-A-P-l VOYAGES JACQUES BOURGAULT ENRG.Jacques Bourgault.opérant sous le nom de : operating under the name of: 4787, 5e Avenue Ouest, Québec, P.Q.La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Aux fins de révoquer le permis No 3486-A, non exploité, confirmé par lettre en date du 28 janvier 1974.IV \u2014 Avis de désistement : La Commission donne avis de désistement des requêtes par les requérants dans les affaires suivantes: QDW-35 a) GÉRARD NOLIN LIMITÉE DOSSIER: 15957-V-S-8 CAUSE : Q-0190 QDW-36 AUTOBUS LANDRY LTÉE DOSSIER: 2178-A- D3 publié dans G.O.Q.No 5 le 2-2-74, page 1120 Region 3 contractor 12.14 An individual person, proprietor of a 1972 Mack tractor truck, serial number: R79S5T 1913, registered in the Province of Québec, to haul the trailer or semi-trailer whose registration number is RL-15420, requests the Commission to issue in his behalf the bulk transportation permit, \"Contractor\" Class, for region No.3, which the Commission would have issued in behalf of Mr.Edgar Boulet.Region 3 artisan 12.15 An individual person, requests the Commission to transfer in his behalf the certificate held by the estate of Edgar Boulet per Mrs.Anita Rodrigue, issued on September 25, 1973, as regards the truck hereinafter described : 1973 Mack, Serial number: R795 5T 1913, registration number in the Province of Quebec: L-13914/73.To haul the trailer or semi-trailer whose registration number is RL-15420.Application for the fixing of rates per ton, per hour and per week, applicable in the James Bay contract.For further information, please refer to the Québec Transport Commission.56438-0 I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to render a decision in the following matter pursuant to the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.For the purpose of revoking permit No.3486-A, not in operation, as confirmed by a letter dated January 28, 1974.IV \u2014 Notice of withdrawal : The Commission gives notice of withdrawal of applications by the applicants in the following proceedings: QDAV-35 (a) GÉRARD NOLIN LIMITÉE FILE: 15957-V-S-8 CAUSE: Q-0190 QDW-36 AUTOBUS LANDRY LTÉE FILE: 2178-A-D-3 published in Q.O.G.No.5 2-2-74, page 1120 56438-o SPEEDWAY EXPRESS LTD., 20, boul.Marie-Victorin.Boucherville, Que., tiré carrier, requérants conjoints joint applicants.Rôle Q-086B Q-501000 D-2 SUCCESSION EDGAR BOULET, Par: Mme Anita Rodrigue.Morisset Station, Dorchester.P.Q.Région 3 entrepreneur 12.14 Personne physique, propriétaire d'un camion tracteur Mack 1972, No de série: R795 5T 1913, immatriculé au Québec, devant tirer la remorque ou semi-remorque dont le numéro d'immatriculation est RL-15420, demande à la Commission de lui émettre le permis de camionnage en vrac, catégorie « Entrepreneur », pour la région No 3, qu'elle aurait émis à M.Edgar Boulet.Rôle Q-0867 Q-501632 JEAN BOULET, St-Prosper, Cté Dorchester, P.Q.Région 3 artisan 12.15 Personne physique, demande de lui transférer l'attestation que possède la succession Edgar Boulet par Mme Anita Rodrigue, émise le 25 septembre 1973, concernant le camion ci-dessous décrit: Mack 1973, No de série: R795 5T 1913, No d'immatriculation au Québec: L-13914/73 Devant tirer la remorque ou semi-remorque dont le No d'immatriculation est RL-15420.Demandons fixation de taux à la tonne, à l'heure et à la semaine sur le contrat Baie James.Pour information additionnelle, adressez-vous à la Commis-ion des transports du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 mars 1974, 106' année, n° 11 2151 V \u2014 Avis des décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement Xo 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of .the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-462\t28-02-74\t6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.\t1-1-90\t2552\t28-04-73\tM-4146\t Décisions La Commission raye le délibéré de la présente cause et ordonne que la présente demande soit référée au quorum composé du juge Bourret et des commissaires Jean-Guy Alain et Jean-Claude Vézeau pour qu'elle fasse partie de leur enquête prescrite dans la décision.QPV-242 MCV-2 MPV-210 TF 28-02-74 26-02-74 27-02-74 Decisions The Commission cancels the writ of consultation in the present case and orders that the present request be^ referred to quorum consisting of Judge Bourret and Commissioners Jean-Guy Alain and Jean-Claude Vézeau.to be included in the inquiry to be conducted by them, as prescribed in the decision.3390-A-C-l AUTOBUS SEPT-ILES LTEE AUTOBUS COTE NORD INC.23262-V BERNARD LEGAULT 634-A MTF-3 1-10-62 3230 1135 17-11-73 26-05-73 02-02-74 Requérant La Commission des transports du Québec (suivant 3vis « Proprio Motu » de vérification de permis) LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE intimée LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE partie requérante a demandé des modifications de tarifs horaires et parcours en vertu de l'article 2.71 du règlement No 2, Règles de Pratique et de régie interne de la Commission des transports, comme suit: Tarifs adultes: Billets: 3 pour SI.00 Billets en livrets: 13 pour $4.00 Argent comptant : $0.40 Etudiants: De 6 à 9 ans \u2014 tarif applicable tous les jours \u2014 De 10 à 18 ans \u2014 tarif applicable les jours de classe seulement.Billets: 5 pour $1.00 Argent comptant: $0.30 Horaires: Du lundi au vendredi inclusivement : 7.15 a.m.à 9.15 a.m.11.15 a.m.à 6.15 p.m.9.15 a.m.à 11.15 a.m.(arrêt du service) départs du centre ville A toutes les 15 et 45 minutes \u2014 passé l'heure, deux autobus en sens inverse.Extension: à Lafontaine et Domaine Laurentien (Lesage), 8.45a.m., 6.15 p.m.Q-60 M-4407 M-1052 Applicant La Commission déclare ne pouvoir donner suite à la demande de la requérante / The Commission declares that is unable to act upon the applicant's request.Rejetée / Rejected The Québec Transport Commission (In consequence of a \"proprio motu\" notice for a verification of permit) LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE defendant LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE applicant, has requested a number of modifications of its hourly rates and of its routes, pursuant to section 2.71 of Regulation No.2, Rules of practice and rules for internal management of the Transport Commission, as follows: Tariffs adults: Tickets: 3 for $1.00 Booklet: 13 for $4.00 Cash: $0.40 Students: 6 to 9 years \u2014 tariff applicable everyday 10 to 18 years \u2014 tariff applicable on school days only.Tickets: 5 for $1.00 Cash fare: $0.30 Timetable: From Monday through Friday inclusive: 7.15 a.m.to 9.15 a.m.11.15 a.m.to 6.15 p.m.9.15 a.m.to 11.15 p.m.(cessation of service) departures from the downtown district every 15 and 45 minutes past the hour \u2014 outside regular hours, two buses in the opposite direction.Extension: to Lafontaine and Domaine Laurentien (Lesage), 8.45 a.m., 6.15 a.m. 2152 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 197i.Vol.106, No.11 Bellefeuille: du lundi au vendredi inclusivement: 7.45 a.m., 11.45 a.m., 3,15 p.m., 4.00 p.m.5.15 p.m.Parcours: Circuit No 1 : (2 autobus) Départ centre ville rue Labelle.direction sud.à gauche rue Montigny-boulevard Labelle (rte 11), à gauche 9ième Rue.à droite 20ième Avenue, à gauche boulevard St-Antoine (rte 41), à droite 24ième Avenue, à droite 22ième Rue, à droite 19ième Avenue, à gauche boulevard St-Antoine (rte 41) à droite boulevard Labelle (rte 11) à droite rue St-Georges.a gauche 106ième Avenue.Rendu à la 106ième Avenue.Lalontaine, tourner à droite sur le boulevard Labelle (rte 11) continuer sur le boulevard des Hauteurs fin du circuit chez les Pères Jésuites, retour boulevard des Hauteurs, nord sur rte 11 à Domaine Laurentien (Lesage), retour rte 11, sud rue Labelle vers centre ville.Circuit No 2: Bellefeuille (1 autobus) 7.45 a.m., départ rue Demartigny (coin boul.Kennedy) rue Lamontagne à aéroport Ste-Marie, retour via rue La-montagne, à gauche boul.Lajeunesse, rue de la Rivière, à droite rue Labelle vers centre ville.11.45 a.m., départ centre ville rue St-Georges (direction nord) à gauche rue de la Rivière, boulevard Lajeunesse, à droite rue Lamontagne vers aéroport Ste-Marie, retour via rue Lamontagne (Domaine Hatin) rue Demartigny, à droite rue Labelle à centre ville.3.15 p.m., départ centre ville rue St-Georges (direction nord) à gauche rue de la Rivière \u2014 boulevard Lajeunesse, à droite sur Lamontagne vers aéroport Ste-Marie, retour via rue Lamontagne \u2014 rue Demartigny, à droite rue Labelle vers centre ville.4.00 p.m.et 5.15 p.m., départ centre ville rue St-Georges (direction nord) à gauche rues Godmer et Demartignv, rue Lamontagne et Domaine Hatin vers aéroport Ste-Marie, retour rue Lamontagne et Demartigny.à droite rue Labelle vers centre ville.Décisions La Commission: Enjoint LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE de reprendre - au plus tard le 15 mars 1974 - et de maintenir le service local de transport public par autobus, tel que déjà autorisé dans les limites de la cité de St-Jérôme, St-An-toine-des-Laurentide8, Lafontaine et Bellefeuille.Et accorde la demande de modification de tarifs, horaires et parcours.Bellefeuille: from Monday through Friday inclusive: 7.45 a.m., 11.45 a.m., 3.15 p.m., 4.00 p.m., 5.15 p.m.Route: \" Route No.1: (2 buses) ., Departure: downtown district, Labelle Street in a southerly direction, on the left Montigny Street \u2014 Labelle Boulevard (Highway 11): on the left, 9th Street; on the right, 20th Avenue, on the left, St.Antoine Boulevard (Highway 41); on the right.24th Avenue; on the right, 22nd Street; on the right, 19th Avenue; on the left St.Antoine Boulevard (Highway 41); on the right Labelle Boulevard (Highway 11); on the right St.Georges Street; on the left, 106th Avenue.Stop at 106th Avenue.\u201e '_ , , .Lafontaine, turn right on to Labelle Boulevard (Highway 11), proceed along Des Hauteurs Boulevard; route ends at Pères Jésuites, return via Des Hauteurs Boulevard, north on Highway 11 to Domaine Laurentien (Lesage), return Highway 11, south Labelle Street towards downtown district.Route No.2: Bellefeuille (1 bus) 7.45 a.m.departure Demartigny Street corner of (Kennedy Boulevard) Lamontagne Street to Ste.Marie Airport, return via Lamontagne Street, on the left Lajeunesse Boulevard, De la Rivière Street, on the right, Labelle Street towards downtown district._ 11.45 a.m.departure from downtown district St.Georges Street (northerly direction) on the left De la Rivière Street.Lajeunesse Boulevard, on the right Lamontagne Street to Ste.Marie Airport, return via Lamontagne Street (Domaine Hatin) Demartigny Street, on the right Labelle Street to downtown district.3.15 p.m., departure downtown district St.Georges Street (northerly direction) \"on the left De La Rivière Street \u2014 Lajeunesse Boulevard, on the right Lamontagne Street to Ste.Marie Airport, return via Lamontagne Street \u2014 Demartigny Street, on the right Labelle Street to downtown district.4.00 p.m.and 5.15 p.m.: Departure downtown district St.Georges Street (northerly direction), on the left Godmer and Demartigny Streets, Lamontagne Street and Domaine Hatin, to the Ste.Marie Airport, return Lamontagne Street and Demartigny, on the right Labelle Street to downtown district.Decisions The Commission: Orders LES AUTOBUS JEROMIENS LTEE to resume - at the latest on March 15.1974 - and to maintain the local service of public transportation by bus as already authorized within the limits of the City of St.Jérôme, St.Antoine-des-Laurentides, Lafontaine and Bellefeuille and grants the requests for mofification of tariffs time-tables and routes.DECISIONS DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QPT-2 TF MPT-2 TF\t22-02-74\t20000-P-l LE TRANSPORT PAR VEHICULE-TAXI Fixation des taux et tarifs Fixing of rates and tariffs\t\t\t02-02-74\tQ-0624\t La Commission modifie sa décision rendue le 29 novembre 1973, concernant la fixation des taux et tarifs pour le transport par véhicule-taxi.QCR-459 26-02-74 Q-22344-V RENE LACHANCE Decisions The Commission modifies its decision rendered on November 29, 1973.respecting the fixing of the rates and tariffs for transportation by taxi-cab.946 26-01-74 Q-605 La Commission révoque le permis de transport No 22344-V./ The Commission revokes transportation permit No.eSS44~V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2153 No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-460\t26-02-74\tQ-23048-V-P-1 TRAVERSE M.S.S.LIMITEE\t\t946\t26-01-74\tQ-604\t Décisions La Commission.1.Revise sa décision QCR-372 du 5 décembre 1973 quant à la remise du montant du dépôt de la partie requérante.2.Décrète le remboursement du dépôt de $100 fait par TRAVERSE M.S.S.LIMITEE au lieu de $200 tel qu'indiqué dans la décision QCR-372.QCR-J61 26-02-74 Q-23286-V-P-1 ROBERT CARRIER Décisions La Commission a établi lors de l'audience du 20 novembre 1973 que EUGENE NADEAU avait dûment confié à l'étude Richard Cliche un mandat de le représenter comme d'ailleurs dans une autre cause appelée le même jour et cette déclaration est déclarée valable.QPV-239 26-02-74 Q-3313-A-P-1 T.E.S.I.(SAGUENAY) LIMITEE Décisions La Commission décrète le remboursement du dépôt de $50 fait par T.E.S.I.(SAGUENAY) LIMITEE, conformément au règlement No 2.QPV-240 26-02-74 Q-1986-A-P-1 LUCIEN GERMAIN Décisions La Commission autorise: a) le transport d'écoliers de St-Prosper aux écoles de St-Stanislas, et retour et ce, le midi seulement.ô) le transport d'écoliers, de St-Stanislas aux écoles de St-Stanislas, et retour, et ce, le midi seulement.c) fixe et décrète, les tarifs déposés avec requête, lesquels taux sont payables par les étudiants fréquentant lesdites écoles.QPV-241 28-02-74 Q-495-A-D-1 Q-495-A-P-1 GERALD FILLION Décisions La Commission: 1.accorde la requête Q-495-A-P-1 R.Q.603 et 2.accorde la requête Q-495-A-D-1 R.Q.419 Decisions The Commission: 1.Revises its decision QCR-372, dated December 5.1973.respecting the reimbursement of the applicant's deposit.2.Orders the reimbursement of the deposit of $100 made by TRAVERSE M.S.S.LIMITEE, and not $200 as indicated in decision QCR-372.323 19-01-74 Q-567 Decisions During the hearing held on November 20, 1973, the Commission established that EUGENE NADEAU had duly commissioned Richard Cliche's lawyer's office to represent him in this matter and also in another case called on the same day; such statement is declared valid.322 19-01-74 Q-554 Decisions The Commission orders the reimbursement of the $50 deposit made by T.E.S.I.(SAGUENAY) LIMITEE, pursuant to Regulation No.2.322 19-01-74 Q-553 Decisions The Commission : (a) Authorizes the transportation of pupils from St.Prosper to schools in St.Stanislas, and return, at lunch-time only.(6) Authorizes the transportation of pupils from St.Stanislas to schools in St.Stanislas, and return, at lunch-time only.(c) Fixes and orders the coming into effect of the tariffs filed with the request, said rates to be paid by the students attending said schools.946 26-01-74 Q-603 Decisions The Commission : 1.Grants request Q-495-A-P-1 R.Q.603 and 2.Grants request Q-495-A-D-1 R.Q.419.SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS QCR-458 25-02-74 Q-13285-V-D-1 BOB R.LAROUCHE INC.Requérante-venderesse Applicant vendor REAL DESCHESNE fidéicommissaire pour Trustee for TRANSPORT REAL DESCHESNE & FILS INC.Requérante-acquéreur Applicant purchaser 119 12-01-74 Q-537 Accordée / Granted 2154 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974.Vol.106, No.11 No QCS-266 QCS-267 QCS-268 QCS-269 QCS-270 QCS-271 QSF-10 MCR-732-TF Date 22-02-74 22-02-74 22-02 71 26-02-74 26-02-74 26-02-74 22 02 71 26-02-74 Requérants Applicant! Q-22753-V-D-1 ANGELO FILLION Voiturier-remorqueur Haulaway operator 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier 23358-V-D-l RENE DUBOIS Voiturier-remorqueur Haulaway operator 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Q-23413-V-D-2 CHARLES-EUGENE GUAY Voiturier-remorqueur Haulaway operator 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Q-l 1865-V-D-l JEAN-MARIE HARVEY Voiturier-remorqueur Haulaway operator 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Q-23501-V-D-1 ANDRE GRENIER Voiturier-remorqueur Haulaway operator Q-6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Q-23445-V-D-2 YVON DRAPEAU Voiturier-remorqueur Haulaway operator Q-6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier 3 C F T A N D-2 LA VILLE DE MATANE Bulletin BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Requérant Demande à la Commission des transports du Québec pour le compte de camionneurs participants, une augmentation des taux pour le transport effectué entre certains points des Etats-Unis et de la province de Québec, desservis par les camionneurs membres du Bureau des Tarifs du Québec, le tout tel qu'il appert au Supplément No 8 du Tarif 400-A, annulant le Supplément No 7 de ce même tarif, augmentation approximative: 2%, conformément à l'article 2.64, section 3 du règlement No 2 concernant la concurrence tarifaire avec transport ferroviaire.En vertu de l'article 2.64 du règlement No 2 sur les règles de pratique et de régie interne de la Commission.G.O.Q.page date 7554 7559 7554 25 7419 7420 28 6600 22-12-73 22-12-73 22-12-73 05-01-74 15-12-73 05-01-74 10-11-73 Cause Case Q-J84 Q-507 Q-486 Q-520 Q-462 Q-531 Q-326 Accordée / Granted Accordée / Granted La Commission décrète qu'elle est inhabile à donner suite à cette demande / The Commission declares that it is unqualified to act upon this request.Accordée / Granted Applicant Requests from the Québec Transport Commission, on behalf of member-carriers, an increase in rates for the transportation services operated between certain points, situated in the United States and in the Province of Québec, and Berved by member-carriers of the Québec Tariff Bureau, the whole as it appears from Supplement No.8 to Tariff 400-A, cancelling Supplement No.7 to this same tariff, approximate increase: 2%, pursuant to section 2.64, division 3 of Regulation No.2 respecting tariff competition with the railway transportation.Pursuant to section 2.64 of Regulation No.2 on the rules of practice and the rules for internal development of the Commission.Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° U 2155 No Date MCR-733-TF MCR-734-TF MCR-735-TF ML-237 MCR-736 MCR-737 MCR-738 MCR-739 MCR-740 MCR-741 MCR-742-TF MCS-349 MCS-350 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 27-02-74 25-02-74 25-02-74 Requérant» Applicants 15578-V CLARKE TRANSPORTATION CANADA LTD.4-V INTER-CITE TRANSPORT LTEE 3718-V-D-l-TF PAUL LAFRANCE TRANSPORT INC.4007-V JEAN-PAUL BEAUDRY Requérant-vendeur A pplicanl-rendor JULIEN BELLAVANCE Requérant-acquéreu r Applicant-purchaser 23508-V-D-l DANIEL HOULE ENRG (Daniel Houle) 23448-V-D-l JACQUES MARTIN 23462-V-D-l CORDY TRANSPORT ENRG.(Jacques Campeau) 23365-V-D-l LUCIEN SALINOVICK 23531-V-D-l FERNAND GUERTIN TRANSPORT ENRG.(Fernand Guertin) 18550-V-D-l TF PUROLATOR COURIER LTD.15911-V-D-l QUEENSWAY TANK LINES LTD.23386-V-D-l LEO FISET Voiturier-remorqueur Haulaway operator 4651-V-D-l CABANO TRANSPORT LTEE Voiturier-roulier / Carrier La Commission abroge à toutes fins sa décision rendue le 9 janvier 1974, qui accordait les demandes des requérants.Bulletin G.O.Q.page date 7260 7260 5589 6612 6981 6979 6815 7415 7415 6823 129 6417 6417 08-12-73 08-12-73 29-09-73 10-11-73 24-11-73 24-11-73 17-11-73 15-12-73 15-12-73 17-11-73 12-02-74 03-11-73 03-11-73 Cause Case M-723 M-722 M-201 M-557 M-679 M-675 M-596 M-752 M-753 M-631 M-914 M-407 M-408 Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.MCS-351 TF MCS-352 MCS-353 MCS-354 MCS-355 MCS-366 TF 25-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 12618-VM CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS TARIFF BUREAU ASSOCIATION 23122-V-D-l WINDSOR FLOYD 22820-V-D-l RHEAULT GAREAU 20211-V-D-l BOWES MOVING & STORAGE LTD.22027-V-D-l LES LAITERIES LECLERC INC.21133-V-D-l TF STAGEY S MOVING (NIAGARA) LTD.The Commission cancels, for all purposes, its decision rendered on January 9, 1974 which granted the applicants' requests.6612 10-11-73 M-558 Accordée / Granted.6419 7412 6609 7413 6609 03-11-73 15-12-73 10-11-73 15-12-73 10-11-73 M-115 M-743 M-549 M-749 M-548 Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée,' Granted. 2156 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 16.1974, Vol.106.No.11 Date 25-02-74 25-02-74 25-02-74 25-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 26-02-74 20-02-74 20-02-74 Requérants A pplicants 1273-DY & 1055-DYV-D-l MOUSETTE CHRYSLER PLYMOUTH LTEE 1278-DY-D-l OMEGA MOTORS (1960) LTD.10762-V-D-l ST-JOVITE TRANSPORT ENRG.703-V-D-2 C.LEBOEUF TRANSPORT INC.1056-DY LE TRIANON AUTOMOBILE LTEE Mise en cause FORD MOTOR CO.OF CANADA LTD.Requérante-venderesse A pplicanl-vendor PAUL NADEAU ROLAND MERCIER Requérants-acquéreurs A ppticant-purchasers 1052-DYV-D-l ROULOTTES DEL-CAN TRAILERS (M.John R.Delves) 1050-DYV-D-l ELMAR LEASING LTD.1093-DY-D-l BOULEVARD DODGE CHRYSLER (1963) LTEE 318-V-D-l BELOEIL ST-HILAIRE TRANSPORT INC.14350-V-D-l D.LECLERC TRANSPORT INC.1080-DY-D-l MAISONNEUVE MEKfTRY SALES LTEE 604-DY & 279-DYV-D-l CITY NATIONAL LEASING LTD.1274-DY 4 1066-DYV-D-l SHEFFORD CHRYSLER PLYMOUTH LTEE 1044-DY & 127-DYV-D-l CLAUDE LEGARE Requérant-vendeur Applicant-ten dor LOCATION JEAN LEGARE LTEE Requérante-acquéreur Applicant-purchaser 602-A MURRAY HILL LIMOUSINE SERVICE LTD.Bulletin 1 K 168 1-19-75 G.O.Q.page date 6820 7262 7411 7411 2972 6976 6815 6975 7760 6819 7411 7410 6820 7262 114 4426 17-11-73 08-12-73 15-12-73 15-12-73 12-05-73 24-11-73 17-11-73 24-11-73 08-11-73 17-11-73 15-12-73 15-12-73 17-11-73 08-12-73 12-01-74 28-07-73 Cause Case M-620 M-731 M-739 M-741 RC « M » 94 M-664 M-601 M-661 M-725 M-612 M-736 M-735 M-621 M-734 M-837 Décisions Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Grantea.Accordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.La Commission déclare de classer le dossier vu que les modi- The Commission orders that the file be closed.Bince the ncations demandées dans cette requête sont déjà comprises modifications requested in this application are already com-dans celles du Rôle M-898 (Dec.: MPV-202 TF).prised in those of roll M-898 (Dec.: MPV-202 TF). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2157 No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\t( page\ti.O.Q.date\tCause Cote\tDécisions MPV-206 TF MPV-207 MPV-208\t26-02-74 26-02-74 26-02-74\t1491-A-D-l LA CIE DE TRANSPORT MASKOUTAINE INC.2096-A-D-5 METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.1742-A-D-l BRISEBOIS BUS LINE (1973) LTD\t\t7413 7261 6217\t15-12-73 08-12-73 27-10-73\tM-746 M-729 M'-384\tAccordée / Granted.Accordée / Granted.Accordée / Granted.PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.a: Validity Period Détails du permis Particulars of permit QS-201 1022-DY et/and 896 DYV-S-1 QS-202 23143-V-S-l 13963-V QS-203 23655-V-S-l 1467-V QS-207 Q-22499-V-S-4 QS-208 Q-3560-A-S-1 QS-209 Q-23663-V-S-1 13963-V QS-204 Q-22928-V-S-1 1467-V QS-205 Q-23656-V-S-1 LEPACK AUTOMOBILE INC.GILLES PELLETIER voiturier-remorqueur haulaway operator SPEEDWAY EXPRESS LIMITED voiturier-roulier / carrier RICHARD DESILETS voiturier-remorqueur haulaway operator TRANSPORT F RENETTE INC.voiturier-roulier / carrier LES TRANSPORTS DE LA BAIE D'HUDSON INC.GERMAIN VALLEE MICHEL DUMONT voiturier-remorqueur haulaway operator SPEEDWAY EXPRESS LTD.voiturier-roulier / carrier PATRICE VACHON voiturier-remorqueur haulaway operator TRANSPORT FRENETTE INC.voiturier-roulier / carrier JEAN-DENIS VACHON voiturier-remorqueur haulaway operator 6 mois 16 months 6 mois / 6' months 31-10-74 6 mois /6 months 6 mois / 6 months Permis spécial - Demande de retrait de la part de la requérante./ Special permit - Application for withdrawal on the part of the applicant.Permis spécial - Gilles Pelletier est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Speedway Express Limited No 13963-V.'Special permit - Gilles Pelletier is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Speedway Express Limited, No.13963-V.Permis spécial - Richard Désilets est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Transport Frenette Inc./ Special permit - Richard Désilets is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Transport Frenette Inc.Permis spécial - De tout point à tout autre point dans un rayon de 500 milles de Matagami, exclusivement pour le transport de marchandises pour le compte de Matagami Ready-Mix Ltd./Special permit-From any point to any other point located 'within a radius of 600 miles from Matagami, exclusively for the transportation of goods on behalf of Matagami Ready-Mix Ltd.Demande de permis spécial rejetée - Transport de personnes handicapées de leur domicile à leur Heu de travail: Le Centre de Travail Polyvalent Gaspésien./ Application for special permit rejected - Transportation of handicapped persons from their homes to their place of employment: Le Centre de Travail Polyvalent Gaspésien.Permis spécial - Michel Dumont est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorquée de Speedway Express Ltd./ Special permit - Michel Dumont is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Speedway Express Ltd.Permis special - Patrice Vachon est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Transport Frenette Inc./ Special permit - Patrice Vachon is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Transport Frenette Inc.Permis spécial - Jean-Denis Vachon est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Transport Frenette Inc./ 2158 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974.Vol.106.No.11 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.1467-V QS-206 Q-23463-V-S-1 QS-210 Q-23662-V-S-1 4724-V QS-211 Q-500547-P-1 QS-212 Q-S0O347-S-I QS-213 Q-4732-V-S-2 QS-214 Q-3323-A-S-1 QS-215 Q-22966-V-S-1 QS-216 Q-23667-V-S-1 QS-217 Q-2482-V-S-1 Nom du requérant Name of Applicant TRANSPORT FRENETTE INC.voiturier-roulier / carrier BERNARD BONNEAU JEAN-GUY CARON voiturier-remorqueur haulaway operator MAGNY TRANSPORT INC.voiturier-roulier / earner TREMBLAY, CHARLES DUFOUR, GILLES GRENIER TRANSPORT INC.Validité: de:.à: Validity Period 6 mois 16 months 6 mois 16 months AUTOCAR PORTNEUF INC.REAL COTE requérant-vendeur applicant vendor FERNAND LAFLAMME requérant-acquéreur applicant purchaser ARRIMAGE ET SERVICE CARTIER INC.CARTIER STEVEDORING AND SERVICES INC.requérante- venderesse applicant vendor NAP.BROCHU INC.requérante-acquéreur applicant purchaeer MME EVELYN COMEAU (Edmond Comenti.décédé) 6 mois IG months 6 mois 16 months Détails du permis Particulars of permit Sperial permit - Jean-Denis Vachon is au thoriied to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Transport Frenette Ine.Permis spécial - Transport et remorquage de maisons mobiles et préfabriquées./ Special permit - Transportation and hauling of prefabricated and mobile homes.Permis spécial - Jean-Guy Caron est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Magny Transport Inc./ Special permit - Jean-Guy Caron is authorised to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Magny Transport Inc.Demande de permis spécial rejetée - Pour donner un service de transport en vrac dans la répion No 9./ Application for special permit rejected -To provide a bulk transportation service in Region No.9.Demande de permis spécial rejetée - Pour donner un service de transport en vrac dans la région No 2./ Application for special permit rejecte ' To provide a bulk transportation service in Region No.2.Demande de permis spécial rejetée - Transport de produits finis manufacturés de Ste-Marie de Beauce à la frontière Québec-Etats-Unis pour le compte de Les Valises Scott Limitée / Application for special permit rejected - Transporta-lion of finished manufactured products from Ste.Marie de Beauce to the Quebec-United States border, on behalf of Les Valises Scott Limitée.Demande de permis spécial rejetée - Modification de l'horaire d'hiver, du parcours No 2, Québec Lac St-Joseph-St-Raymond./ Application for special permit rejected - Modification of the winter timetable for route No.2, Quebec-Lake St.Joseph-St.Raymond.Demande de permis spécial rejetée - De Montréal à Richmond et South Durham, pour le transport de moulée, engrais chimique en sacs pour le compte de Centre Agricole Co-op et Johann Mobil Feed Mill Inc./ Application for special permit rejected - From Montreal to Richmond and South Durham, for the transportation of feed, fertilizers in bags, on behalf of Centre Agricole Cc-op and Johann Mobil Feed Mill Inc.Permis spécial - Transport par semi-remorquea ou par fardiers, de machinerie, machinerie lourde, équipement lourd ou objets qui nécessitent l'usage d'équipement spécialisé, à et entre tous les endroits situés dans un ravon de cinquante (60) milles de Port-Cartier./ Special permit - Transportation, by semi-trailer or float, of machinery, heavy machinery and heavy equipment or goods which require the use of special equipment, to and between all points located within a radius of fifty (SO) miles from Port-Carlier.Permis spécial - Transport de St-Malachie à tous les endroits situés: a) sur une distance ne dépassant pas 5 milles: b) dans un rayon de 30 milles: e) de St-Malachie à Sherbrooke pour le transport des produits de l'érable; d) St-Malachie et retour.Spécial permit - Transportation from St.Mala- chie to any point located: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' 11 2159 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars of permit QS-218 Q-32-V-S-1 QS-219 Q-37-A MTF-1 QS-220 Q-257-V-S-I QS-221 Q-7190-V-S-1 TRANSPORT DALLAIRE LIMITEE DALLAIRE TRANSPORT LTD.AUTOBUS DESHAIES LIMITEE TREMBLAY EXPRESS LIMITEE L.CLAVEAU TRANSPORT (1974) ENRG.MS-474 22652-V-S-l MS-475 23651-V-S-l MS-476 16168-V-S-l MS-477 14980-V-S-l CHAPUT TRANSPORT ENR'G.ALBERT ST-PI ERRE requérant / applicant BRAZEAU TRANSPORT INC.requérant-conjoint joint-applicant PARENT TRANSPORT LIMITED FRANK D.COLLETT 6 mois j6 months 6 mois / 6 months un an moins un jour one year minue one day 6 mois / 6 months Décision finale de la commission (un an moins un jour) Final decision of the Commission (one year minus one day) Décision finale de la commission (un an moins un jour) Final decision of the Commission (one year minus one day) Décision finale de la commission (un an moins un jour) Final decision of the Commission (one year minus one day) Décision finale de la commission (un an moins un jour) Final decision of the Commission (one year minus one day) (a) .over a distance of not more than 6 miles; (b) within a radius of 30 miles; (c) between St.Malachie and Sherbrooke, for the transportation of maple products.(d) St.Malachie and return.Permis spécial - De Montmagny à St-Isidore, St-Anselme, St-Maxime et Ste-Marie-de-Beauce pour le transport par camion isotherme, de viance fraîche, pour le compte de Canada Packers Ltd./ Special permit - From Montmagny to St.Isidore.St.Anselme, St.Maxime and Ste.Marie-de-Beauce, for the transportation of fresh meat, by temperature-controlled truck, on behalf of Canada Packers Ltd.Permis spécial - modification de tarifs./ Special permit - Modicafition of tariffs.Permis spécial - La détentrice est autorisée à louer à long terme, de Ryder Truck Rental Limited, 6 véhicules motorisés./ Special permit -the permit-holder is authorized to lease 6 motorized vehicles, on a long-term basis, from Ryder Truck Rental Limited.Permis spécial - Transport de St-Coeur-de-Marie dansun rayon de a) 5 milles b) 30 milles c) St-Coeur-de-Marie, Lac St-Jean, Roberval, Chicoutimi.Special permit - Transportation from St.Coeur-dc-Marie to any point located within a radius of (a) Smiles (b) 30 miles (c) and St.Coeur-de-Marie, Lake St.John, Roberval, Chicoutimi.Permis spécial - De St-Pie-de-Bagot à Chambly Canton et Montréal, et retour./ Special permit -From St.Pie-de-Bagot to Chambly Township and Montreal, and return.Permis spécial - Albert St-Pierre est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Brazeau Transport Inc./ Special permit - Albert St.Pierre is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc.Permis spécial - Entre Montréal, P.Q.et St-John, Woodstock et Frédéricton, Nouveau-Brunswick en utilisant le piggy-back de la compagnie de chemins de fer Pacifique Canadien, et retour./ Special permit - Between Montreal, P.Q.and St.John, Woodstock and Fredericton, New-Brunswick utilizing the piggyback services of the Canadian Pacific Railway Company, and return.Permis spécial - Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de colis légers./ Special permit - Montreal and ail points located over a distance of not more than 6 miles from the limits of said City, for the transportation of light parcels. 2160 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars of permit MS-478 23658-V-S-l MS-479 U519-V-S-4 M8-480 471-V-S-l MS-481 12288-V-S-l BRIAN HILCHEN requérant / applicant KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.requérante conjointe joint applicant COWANSVILLE EXPRESS INC.GLENGARRY TRANSPORT LTD.THE ADLEY CORPORATION MS-*82 ROBERT MCKEOWN 23648-V-S-l QS-224 Q-364-A-S-2 AUTOBUS DUPONT LIMITEE Décision finale de la commission (un an moins un jour) Final decisio of the Commission (one year minus one day) 8 mars 1974 March S.1974 Décision finale de la commission (un an moins un jour) Pinal decision of the Commission (one year minus one day) 5 jours / S days Valide tant que 50% des actions ordinaires appartiendront A.la même personne.Valid as long as 60% of the common shares shall belong to the same person.Permis spécial - Sendee de voiturier-remorqueur pour le compte et selon les clauses de Kingsway Freight Lines Ltd.No 17376-V qui agira comme courtier en transport./ Special permit -Haulaway service according to the clauses of permit No.17376-V held by Kingsway Freight Lines Ltd.and on behalf of the latter, which will operate as transport broker Permis spécial - Autorisation accordée pour louer de Triad Truck Lease Québec Ltd., le véhicule suivant: « 1974 International Straight Truck »/ Special permit \u2014 Authorization granted to lease the following vehicle from Triad Truck Lease Quebec Ltd: \"1974 International Straight Truck\".Permis spécial - De Montréal à la frontière Québec-Ontario (port d'entrée: Rivière-Beaudette) en transit à travers la province d'Ontario via la frontière Ontario-Etats-Unis (ports d'entrée: Cornwall, Roosevelt Town) en transit aux Etats-Unis via la frontière Etats-Unis-Québec (port d'entrée: Réserve de St-Régis) à la Réserve de St-Régis pour le transport de matériaux de construction servant à l'érection d'une école et retour avec marchandises avariées ou refusées pour le compte de Noel Couture Construction Ltd./ Special permit - From Montreal to the Québec-Ontario border (port of entry: Rivière-Beaudette) in transit through the Province of Ontario via the Ontario-United States border (ports of entry: Cornwall, Roosevelt Town) in transit in the United States via the United States-Quebec border (port of entry: St.Régis Reserve to the St.Régis Reserve for the transportation of building materials for the construction of a school and return with damaged or refused goods on behalf of Noel Couture Construction Ltd.Permis spécial - Autorisation accordée pour louer de Canamericain Auto Lease & Rental Ltd.le véhicule suivant: Ford 1972./ Special permit -A uthorization granted to lease the following vehicle from Canamerican Auto Lease & Rental Ltd: 197S Ford.Permis spécial - De Montréal à la frontière Québec-Ontario (tous ports d'entrée), pour le transport, par équipement spécialisé des marchandises de F.M.Welding Inc./ Special permit - From Montreal to the Québec-Ontario border (all ports of entry), for the transportation, by special equipment, of the products of F.M.Welding Inc.Demande de permis spécial rejetée.a) Service touristique à horaire fixe de Ste-Foy, Québec au Mont-Ste-Anne et au Cap-Tourmente en desservant les motels et hôtels situés le long du parcours; b) De tout endroit situé dans le territoire de la Communauté Urbaine de Québec au MontS-te-Anne et Cap-Tourmente.Application for special permit rejected.(a) Tourist service on fixed schedule, from Ste.Foy, Québec, to Mount Ste.Anne and to Cap-Tourmente, serving the motels and hotels located along the route; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' 11 2161 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à Validity Period Détails du permis Particular) of permit QS-222 23236-V-S-l CORMIER & RENAUD INCORPOREE 01/02/75 QS-223 Q-7041-V-S-2 TRANSPORT AMEDEE CAYER INC.6 mois 6 months (b) From any point located within the territory of the Québec Urban Community to Mount Ste.Anneandto Cap-Tourmente.Permis spécial - De Hâvre-Aubert et de tous points situés sur les lies-de-la-Madeleine à la frontière de l'Ile-du-Prince-Edouard (port d'entrée : Souris), via le service de traversier opérant entre Cap-aux-Meules et Souris, pour le transport de marchandises destinées à/ou provenant de Souris et Charlottetown, I.P.E., et Monc-ton, N.B./ Special permit - From Hâvre-Aubert and from all pointe located on the Magdalen Islande to the border of Prince Edward Island (port of entry: Souris), via the ferry service operating between Cap-aux-Meules and Souris, for the transportation of goods destined tofor originated from Souris and Charlottetown, P.E.I., and Moncton.N.B.Permis spécial : a) De St-Pascal et Ste-Hélène-de-Kamouraska à ailleurs dans la province.6) De St-Pascal et Ste-Hélène-de-Kamouraska aux frontières Québec-Ontario; c) De St-Pascal et Ste-Hélène-de-Kamouraska aux frontières Québec-Etats-Unis (tous ports d'entrée) : d) De St-Pascal et Ste-Hélène de Kamouraska aux frontières Québec - Nouveau-Brunswick (tous ports d'entrée), destination: tous les points du Nouveau-Brunswick pour le transport de tous produits fabriqués par P.E.Boucher Ltée, et retour avec tout matériel servant à la production de telles marchandises pour le compte de P.E.Boucher Ltée, de St-Pascal.(a) From St.Pascal and Ste.Hélène-de-Kamouraska to any point in the Province; (b) From St.Pascal and Ste.Hélène-de-Kamou-raska to the Québec-Ontario border; (c) From St.Pascal and Ste.Hélène-de-Kamou-raska to the Quebec-United States border (all ports of entry); (d) From St.Pascal and Ste.Héléne-de-Kamouraska to the Québec-New Brunswick border (all ports of entry), destination: any point in New Brunswick for the transportation of all products manufactured by P.E.Boucher Ltée, and return with any material used for the production of such goods, on behalf of P.E.Boucher Ltée, of St.Pascal.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QL-117 QCS-273 \u2022\t06-03-74 07-03-74\t1257-DY-D-l LA COMPAGNIE DE LOCATION D'AUTOMOBILES DE SEPT-ILES INC.18430-V PORLIER EXPRESS INC.\t\t4807 3374\t18-08-73 02-06-73\tQ-54 Q-2402\tRejetée / Rejected 2162 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 1G, 7974, Vol.106, No.11 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérante\t\t\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\t\tCote\t Décisions La Commission accueille en partie la demande de la requérante; a) De Sept-IIes à Port-Cartier et retour, pour le compte de RAVON1ER QUEBEC INC.: 6) De Sept-IIes et Port-Cartier aux sites des opérations forestières de RAYONIER QUEBEC INC.QCS-274 07-03-74 18430-V PORLIER EXPRESS INC.Décisions La Commission accorde le service suivant : Du port de la ville de Port-Cartier aux sites des opérations forestières du RAYONIER QUEBEC INC.pour le remorquage de maisons mobiles.QPV-243 07-03-74 3331-A-D-C-l DENIS BOLDUC Décisions La Commission révoque, à toutes fins, que de droit, le permis 3331-A-D-C-l détenu par DENIS BOLDUC.QCS-275 07-03-74 Q-18430-V-D-1 PORLIER EXPRESS INC.QCS-276 07-03-74 Q- 18430-V PORLIER EXPRESS INC.QCR-466 06-03-74 Q-22727-V-P-1 LUCIEN LEBLANC Décisions La Commission revise sa décision QCR-316, du 6 novembre 1973, et modifie le remboursement du dépôt de S50 comme devant se lire $25, tel qu'effectivement, versé par le requérant.QCR-467 06-03-74 Q-19296-V-P-1 BEL-MONT TRANSIT INC.Décisions La Commission décrète la révocation du permis spécial QS-86, émis le 5 novembre 1973.à BEL-MONT TRANSIT INC.QCR-463 06-03-74 Q-32-V-P-1 TRANSPORT DALLAIRE LTEE Décisions La Commission revise sa décision QCR-304 et modifie la remise du dépôt de TRANSPORT DALLAIRE LTEE qui devra se lire comme suit: Décrète le remboursement du dépôt de $100 effectué par la requérante.QCR-464 06-03-74 Q-8642-V-P-1 GOSSELIN EXPRESS LTEE Décisions La Commission annule les clauses q, x et y du permis 8642-V et modifie les clauses b.t et r dudit permis.QCR-465 06-03-74 Q-22814-V-P-1 TRANSPORT BERNARD LTEE Décisions La Commission décrète l'annulation, a toutes fins que de droit, de la clause c du permis No 22814-V et de la restriction y afférant, Décision» The Commission grants in part the request of the applicant; ., w (a) From Sept-IIes to Port-Cartier and return, on behalf of RAYONIER QUEBEC INC.: (6) From Sept-IIes to Port-Cartier to the forestry operation sites of RAYONIER QUEBEC INC.6250 27-10-73 Q-275 Decisions The Commission authorizes the following service: From the port of the Town of Port-Cartier to the forestry operation sites of RAYONIER QUEBEC INC., for the haulage of mobile homes.I 4924 I 25-07-73 Q-86 I Decisions The Commission révoques, for all legal purposes, permit 3331-A-D-C-l held by DENIS BOLDUC.6600 3607 947 10-11-73 12-02-74 26-01-74 Q-324 Q-2408 Rejetée / Rejected Accordée / Granted Q-606 Decisions The Commission revises its decision QCR-316, dated November 5, 1973, and modifies the amount of the deposit to be reimbursed which should not read: $50, as specified, but $25.i.e.the sum actually deposited by the applicant.947 26-01-74 Q-607 Decisions The Commission orders the revocation of special permit QS-85.issued on November 5.1973, to BEL-MONT TRANSIT INC.948 26-01-74 Q-610 Decisions The Commission revises its decision QCR-304 and modifie* .the provision regarding deposit made by TRANSPORT DALLAIRE LTEE, which shall read as follows: Orders the reimbursement of the sum of $100 deposited by the applicant.'JI7 26-01-74 Q-609 Decisions The Commission cancels clauses q, x and y of permit 8642-V and amends clauses s, t and t of said permit.947 26-01-74 Q-608 Decisions The Commission orders the cancellation, for all legal purposes, of clause c of permit No.22814-V and of the restriction attaching thereto. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' 11 2163 No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-468 QCR-469 QCS-272\t07-03-74 07-03-74 29-02-74\tQ-1756-V-D-1 TRANSPORT PHILIPPE INC.Q-1467-V-D-1 FRENETTE TRANSPORT INC.Q-23576-V-D-l JEAN-MARIE LABRANCHE voiturier-remorqueur haulaway operator 6793-V BRAZEAU TRANSPORT INC.voiturier-roulier / carrier\t\t7418 7418 324\t15-12-73 15-12-73 19-01-74\tQ-454 Q-455 Q-565\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 56438-0 Places d'affaires dans la Province Places of Business in the Province DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORPORATION Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORPORATION» est: 2545, avenue Delorimier, Montréal, province de Québec.\u2022T4K 3P7.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56497-0 Perreault & Rivet.DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORPORATION Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"DIVERSIFIED PRODUCTS TRUCKING CORPORATION\" is 2545 Delorimier Avenue, Montreal, Province of Québec.J4K 3P7.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56497-o Attorneys for the company.VEILLETTE TRANSPORT CIE LTEE Le présent avis désire corriger la publication du 23 février 1974 concernant le siège social de la compagnie sus-mentionnée, permis No 3129-V, comme étant: 1330, boul.Ducharme, La Tuque, comté Laviolette, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56498-0 Perreault & Rivet.VEILLETTE TRANSPORT CIE LTEE The following notice is to correct the publication of the 23rd of February, 1974, concerning the head office of the above-mentioned company, permit No.3129-V, as being: 1330 Ducharme Blvd., La Tuque, Laviolette County, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56498-0 Attorneys for the Company.SHERWOOD W.HUME (d/b/a: Hume Equipment) Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « SHERWOOD W.HUME (d/b/a: Hume Equipment)', permis No 22673-V est 7374, rue Champlain, Verdun, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56544-0 Perreault & Rivet.SHERWOOD W.HUME (d/b/a: Hume Equipment) Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"SHERWOOD W.HUME (d/b/a: Hume Equipment)\" permit No.22673-V is 7374, Champlain St., Verdun, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56544-0 Attorneys for the Company. 2164 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- 106, No- 'I KEYSTONE TRAILER RENTALS LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « KEYSTONE TRAILER RENTALS LTD.», permis No 462-D Y V, est 2240 -43e Avenue, Lachine, Québec, 631-9888.Le procureur de la compagnie, 56521-0 Monroe Abbey, c.r.E.& W.WILLS CARTAGE LIMITED Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « E.& W.WILLS CARTAGE LIMITED », permis No 22375-V est 6655, Côte des Neiges, Suite 225, Montréal, province de Québec.Les procureurs de la requérante, Paquette, Paquette, 56542-0 Perreault & Rivet.KEYSTONE TRAILER RENTALS LTD.Notice is given that the address, for tie Provmçe of Québec, of \"KEYSTONE TRAILER RENTALS LTD.\", Permit No.462-DYV, is 2240 -43rd Avenue, Lachine, Québec, 631-9888.Monroe Abbey, q.c, 56521-0 Attorney for the Company.E.& W.WILLS CARTAGE LIMITED Notice is given that the address, for the Province of Québec of \"E.& W.WILLS CARTAGE LIMITED\", permit No.22375-V is 6655 Côte des Neiges.Suite 225, Montreal, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56542-q Attorneys for the Petitioner.SHERWOOD HUME TRANSPORTATION LTD.SHERWOOD HUME TRANSPORTATION LTD.Avis est donné que l'adresse, pour la province de Québec, de la compagnie « SHERWOOD HUME TRANSPORTATION LTD.», permis No 22673-V est 7374, rue Champlain, Verdun, province de Québec.Les procureurs de la compagnie, Paquette, Paquette, 56543-0 Perreault & Rivet.Notice is given that the address, for the Province of Québec, of \"SHERWOOD HUME TRANSPORTATION LTD.\", permit No.22673-V is 7374 Champlain St., Verdun, Province of Québec.Paquette, Paquette, Perreault & Rivet, 56543-0 Attorneys for the Company.Curatelle publique Succession Jean-Marc Lavoie Succession de Jean-Marc, Lavoie, en son vivant de Ste-Foy, Québec, décédé le 4 mars 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec 9310, boul.St-Laurent, Montréal, P.Q.H2N 1N6.56445-0 Succession William James Paton Succession de William James Paton, en son vivant de Québec, décédé le 26 mai 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, P.Q., H2N 1N6.56504-o Public Curatorship Estate of Jean-Marc Lavoie Estate of the late Jean-Marc, Lavoie, in his lifetime of Ste-Foy, Québec, deceased on March 4, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971) he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Lawrence Blvd., Montreal, P.Q.H2N 1N6.56445-0 Estate of William James Paton Estate of the late William James Paton, in his lifetime of Québec, deceased on May 26, 1973.The undersigned hereby gives notice thet under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que, H2N 1N6.56504-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2165 Succession Georges-Etienne Marchand Succession de Georges-Etienne, Marchand, en son vivant de St-Philippc d'Argenteuil, décédé le 13 avril 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, P.Q.H2N INS.56446-0 Estate of Georges-Etienne Marchand Estate of the late Georges-Etienne, Marchand, in his lifetime of St-Philippe d'Argenteuil, deceased on April 13 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St-Lawrence Blvd.Montreal, P.Q.H2N 1N6.56446-0 Ventes pour taxes Sales for taxes Municipalité du comté de Saguenay Avis public est par les présentes donné, par le soussigné Paul Bouchard, secrétaire-trésorier de la corporation du comté de Saguenay.que les immeubles ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique à l'Hôtel de Ville de Tadoussac chef lieu du conseil de comté de Saguenay, JEUDI le QUATORZIÈME jour de MARS 1974 à DIX heures a.m.pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts plus les frais encourus subséquemment à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant cette date.Municipality of County of Saguenay Public notice is hereby given by the undersigned, Paul Bouchard, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Saguenay, that the immoveables hereinafter listed will be sold by public auction at the Town Hall of Tadoussac, County Seat of the County of Saguenay, on THURSDAY, the FOURTEENTH day of MARCH, 1974, at TEN o'clock a.m., to cover the payment of municipal and school taxes together with the interest, thereon plus the costs subsequently incurred, unless said taxes, interest and costs are paid prior to the date of the sale.Ste-Anne-de-Portneuf \u2014 Ste.Anne-de-Portneuf Propriétaires Owners Lots et Rang Lots and Range Taxes mun.M unie, taxes Taxes scol.School taxes Frais Costs Total Emond.Ulysse.5 R.B Emond, Ulysse.63 R.B Foster.Raymond.274 R.B Jolicoeur, Leopold.288 R.B Tremblay, Fernando.278 R.B Tremblay, Léonard.269 R.B $ 96.75 675.00 281.25 424.29 499.50 238.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 S 98.75 677.85 283.25 426.29 501.50 240.60 St-Paul-du-Nord \u2014 St.Paul-du-Nord Tremblay, Roméo (Fils).1 emplacement.No Cadastre Mille Vaches.100, Rg A, Seigneurerie $8.99 $ 8.45 $17.44 1 emplacement.Cadastre No.100, Rge A, Mille Vache» Seigniory.Fait à Grandes-Bergeronnes, ce 20 février 1974.Le secrétaire-trésorier, 56289-10-2-o Paul Bouchard.Given in Grandes-Bergeronnes, this February 20, 1974.Paul Bouchard, 56289-10-2-o Secretary-Treasurer. 2166 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Municipalité du comté de Pontiac Avis public est par le présent donné par le soussigné, C.Robillard, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de Pontiac, que les terrains ci-après décrits seront vendus à l'enchère publique, à l'édifice du comté, Campbell's Bay, Québec, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MAI, 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour les cotisations et frais dus aux municipalités ci-après mentionnées, à moins lesdites taxes et frais encourus ne soient payés avant le jour fixé pour la vente.Municipality of the County of Pontiac Public notice is hereby given by C.Robiliard, Secretary-Treasurer of the Municipality of the County of Pontiac, that the lands hereinafter mentioned will be sold by public auction at the County Building Campbell's Bay, Québec, on THURSDAY, the NINTH day of MAY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon, for the assessments and costs due the municipalities hereinafter described, unless they be paid to me with costs incurred, before the day fixed for the sale.Canton de Aldfield \u2014 Township of Aldfield \t\t\t\t\tTaxes\t\tTaxes\t\t\t\t Nom sur rôle\tSuperficies\t\tNo du lot\tRang\tmunie.\t\tscol.\tFrais\t\tTotal\t Name on roll\tArea\t\tLot No.\tRange\tMunie.\t\tSchool\tCosts\t\t\t \t\t\t\t\ttaxes\t\ttaxes\t\t\t\t \t40.000 p.c.-\ts.f\tP.17.\t1\t$ 80\t83\tt 172.73\tt 40\t43\tS 293\t99 \t28,175 p.c.-a.f-\t\tP.34A.\t1.\t90\t46\t119.28\t35\t17\t244\t91 \t6,000 p.c.-\t».f.\tP.44 A.\t\t43\t16\t\t15\t18\t58\t34 Peel, John.\t5,000 p.c.-s.f.\t\tP.15B.\t2.\t20\t03\t\t12\t40\t32\t13 \t\t\tSubdiv.64\t\t\t\t\t\t\t\t \t11,428 p.c.-s.f.\t\tP.15B\t\t28\t21\t\t13\t39\t41\t00 \t\t\tSubdiv.122a\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\tet / and b\t\t\t\t\t\t\t\t Beaudoin, Ligouiri.\t13,000 p.c.-i.f.\t\tP.14B-62.\t2.\t14\t07\t7.61\t12\t60\t34\t28 \t\t\tP.15B-\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t240A et / and\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t241\t\t\t\t\t\t\t\t \t10,000 p.c-\tJ.f.\tP.90.\tEst / East\t72\t34\t\t18\t92\t93\t26 Belisle, Real____\t20,000 p.c-\ts.f.\t\t4\t15\t87\t\t11\t90\t27\t77 McLasham, Janet.\t10,000 p.c-\t3.f.\tP.34.\t4.\t14\t27\t28.28\t15\t11\t57\tGO \t12,500 p.c-\tS.f.\tP.5.\t5.\t15\t94\t\t11\t91\t27\t86 \t\t\tSubdiv.32\t\t\t\t\t\t\t\t \t25.000 p.c-\t3.1.\tP.6\t5.\t82\t42\t\t19\t89\t102\t31 \t\t\tSubdiv.38\t\t\t\t\t\t\t\t \t21,700 p.c-\t3.1.\tP.2B.\t8.\t33\t55\t\t14\t03\t47\t58 Inconnu / Unknown.\t7,500 p.c.-\t3.f.\tP.2A.\t8.\t72\t08\t\t18\t65\t90\t73 Cousineau, Evelyne.\t70,454 p.c-\tB.f.\t3 P.4.\t8.\t34\t17\t32.10\t17\t95\t84\t22 Lebrun, Marcel.\t21,075 p.c-\ts.f.\t2 P.3.\t8.\t126\t75\t93.92\t36\t48\t257\t15 \t67,343 p.c.-\tS.f.\t4 P.3.\t8.\t85\t90\t64.14\t28\t00\t178\t04 \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Canton de Allumette Island E.\u2014 Township of Allumette Island E.Gagnon, John G.Gagnon, John G.Gaudette, Lomie Gaudette, Lomie Gaudette, Lornie Gaudette, Lornie St.Cyr, Lennox.100 acres.100 acres.30 acres.38 acres.26 acres.100' x 128' 1 acre.13.14.12.13.3A.3B.P.28 \tS 34.60\tS 109\t68\t$ 27\t31\tî 171\t59 \t34.60\t109\t68\t27\t31\t171\t59 \t14.38\t33\t84\t15\t79\t64\t01 \t14.38\t33\t84\t15\t79\t64\t01 \t28.72\t67\t68\t21\t57\t117\t97 \t25.13\t59\t22\t20\t12\t104\t47 \t44.60\t53\t87\t21\t82\t120\t29 Canton de Allumette Island \u2014 Township of Allumette Island Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Sikorski, Mme / Afra.J.R.Sikorski, Mme / Mrs.J.R.Robishaw, Wilmour.Robishaw, Wilmour.Dubeau, Alcide et / and Lamarche, Léo P.41A.P.43A.N.P.30.N.P.29A S H 39.6 6 E 5 3 t 11.45 567.00 *5.27 60.69 16.05 S 45.16 2,278.22 57.96 123.66 39.70 S 16.79 351.43 19.99 32.12 16.57 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2167 Canton de Bristol \u2014 Township of Bristol Nom sur rôle Name on roll Charbonneau.M.et Mme / Mr.and Mrs.Jean-Paul Gibbons, M.et Mme / Mr.and Mrs.Cari Lamothe, Suce./ Est, Leonard- Segouin, Suce./ Est.Paul.Yenson, Douglas.Yenson, Douglas.Prudhomme, Mme / Mrs.Marilyn Prudhomme, Mme / Afrs.Marilyn Prudhomme, Mme / Mrs.Marilyn Superficies Area 1 acre.80'x 120'.25 acres.50' x 100'.50' x 100'.18' rue / street No du lot Lot No.P.10B.P.13A.P.7A.P.9A E'.H de lof 6.de/ofW.M P.14A P.14A.P.11-102.P.11-103.P.11-91.Rang Range 6.0.11 I 6 5.1 l l Taxes munie.\tTaxes scol.Munie, taxes\tSchool taxes $ 43.66\tt 229.75 5.30\t12.98 37.92 14.14 46.95\t17.67 117.54 69.95 7.97 86.92 8.84 5.30\t213.41 24.67 14.80 Frais Costs 8 42.81 12.19 16.67 25.80 24.03 10.96 46.04 14.02 12.41 Canton de Bryson Village \u2014 Township of Bryson Village Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Coates, Mary.Coates, Mary.Coates, Mary.Devlin, Mme / Afra.Francis Devlin.Mme / Mrs.Francis Rioux, Marc.260.261.262.23.223.428-3-7 $ 6.88\t$ 7.17\t$ 11.68 6.88\t7.17\t11.68 26.80\t13.92\t14.89 \t153.38\t28.41 \t253.08\t40.37 291.28\t551.78\t111.17 Village de Campbell's Bay \u2014 Village of Campbell's Bay Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Allard, Mme I Mrs.Hélène.Lawn, Mary, Cora & Clifford.Belland, Wm.Jr.Kluke, Henry.P.123-24 P.240.P.4.P.1.$390.95 62.00 52.94 10.80 348.15 35.63 72.09 47.90 $ 98.69 21.72 25.00 17.04 Canton de Village de Chapeau \u2014 Township of Village of Chapeau Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Fitzparick, Joseph Succ./ Est.Giroux, Noak Succ./ Est.Raymond, Edward.Soucie, Allan.Soucie, Allan.Soucie, Allan.146.P.149, 150 P.157- P.74.P.74.P.76.$ 23.69 41.40 23.00 39.06 39.05 39.05 136.44 358.42 130.50 100.08 100.08 100.08 29.22 57.98 28.42 26.70 26.70 26.70 Canton de Chichester \u2014 Township of Chichester Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Venasse, Allan.\t\tP.21.\t1.\t$ 13.20 41.80\t$ 169.65 141.33 256.26\t$ 31.94 26.96 45.77\t$ 214.79 168.29 343.83 \t\tP.18.\t1.\t\t\t\t \t\tP.20.\t1.\t\t\t\t Canton de Dorion \u2014 Township of Dorion\t\t\t\t\t\t\t \t\t5.\t7.\t$ 5.09\t\t$ 10.62\t$ 15.71 \t\t\t\t\t\t\t 2168 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- 106, No.11 Village de Fort Coulonge \u2014 Village of Fori Coulonge Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Nonrsur rôle Same on roll Superficie Area No du lot Lot No.Rang Range Taxes munie.Munie, taxée Taxes scol.School taxes Frais Costs Graveline, Richard & Zampora Durocher, Emily & Arthur.Bertrand, Gilles.Duquette.Alcide.Doyle, Frank.Doyle.Frank.Romain.Burke.Romain.Burke.80 acres.8,900 p.c.-s.f.P.1-3.426.43-2.294.P.211.IV 211 P.252.P.255-2 $562.46 47.26 287.37 4M.34 4.20 470.25 34.50 86.88 251.91 20.82 20.81 297.60 15.16 $133.93 19.81 10.43 74.71 12.50 12.50 104.07 12.32 Canton de Clapham \u2014 Township of Clapham Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Collins.C.& Paris.F.Collins.C.& Paris.F.Kluke, Frank Sr.Succ./ Est.Bâtisses seulement Buildings only Paradis Fish & Game Club.Stewart, Robert.Cormier, Jérôme.Beauregard, Florimond.Beauregard, Florimond.I.-m tli if i Gilles.100 acres.49 acres.Yt acre.100 acres.17.14C.49.P.19.8.P.8B.11.P.35.16.1\t$ 61.21\t$ 35.90\t$ 21.65\t$ 118.76 2.\t18.79\t6.78\t13.07\t38.64 4\t14.41\t10.47\t12.99\t37.87 2.\t46.78\t35.58\t19.88\t102.24 3.\t27.43\t53.05\t19.66\t100.14 7.\t10.00\t87.97\t21.76\t119.73 3.\t10.00\t47.85\t16.94\t74.80 2.\t34.00\t80.44\t23.73\t138.17 C.\t6.45\t42.87\t15.80\t64.12 Canton de Grand Calumet \u2014 Township of Grand Calumet Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Jolicoeur, Gérard.Lebac, Gaétan.Lemaire, Victor.Newberry, Alphir.Paquin.Hildege.Ryan, Bernadette (Newell).Hamelin, Mme / Mrs.Rebecca Hamelin, Gerald.Hamelin, Gerald.Hamelin, Gerald.Hamelin.Gerald.Hamelin, Gerald.Hamelin, Gerald.Hamelin, Gerald.LaSalle, Joseph.Last, Roy.Lamothe, George.Laporte, Arnold H.Laporte, Arnold H.Ladouceur, Ehlen.Ladouceur, Ehlen.Meilleur.Albert.Tremblay, Alexandre.Tremblay, Alexandre.Tremblay, Alexahdre.Tremblay, Alexandre.Tremblay, Alexandre.Tremblay, Alexandre.6.800 p.c.-s.f.49 acres.50 acres.50 acres.100 acres.36 acres .23 acres .60 acres .>4 acre.2 acres.3,000 p.c.-s.f.140 acres.156 acres.1 acre.2^ acres.99>4 acres.60^ acres.104 acres.60 acres.10 acres____ 50 acres 17B.P.2.12C.P.ISA.130.P.14G.P.14A.19C.3B.P.20A.20A.32A.21A.2B.P.8F.P.9A.P.7.17., 18.P.7A.P.6.14A et land 140 P.8A.P.9A.P.9B.10A.P.9A.29A.1.3.1.1.1.1.1.3.7.7.3.8.3.7.4.2.Nord North Nord North Nord North 6.2.1.1.1.1.2.2.$109.16 147.31.150.154.01 .37.23.295.If, 17 78 SO 64.27 25 38 4 27 240 46 27 398 26 3 14 338.94 133.68 251.46 222.59 104.35 139.96 399.77 244.38 99.75 62.37 715.47 45.34 47.37 207.66 256.00 168.16 20.33 30.70 4.53 04.00 $ 63.77 28.00 57.84 40.53 22.52 44.89 76.52 50.30 26.46 20.29 131.31 17.46 17.82 44.31 50.40 37.87 13.36 15.51 18.30 11.04 20.96 38.91 15.63 13.29 57.84 13.17 10.40 11.74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2169 Canton de Huddersfield \u2014 Township of Huddersfield \t\t\t\tTaxes\tTaxes\t\t Nom sur rôle\tSuperficie\tNo du lot\tRang\tmunie.\tscol.\tFrais\t \t\t\t\t\t\t\tTotal Name on roll\tArea\tLot No.\tRange\tMunie.\tSchool\tCosts\t \t\t\t\ttaxes\ttaxes\t\t Leach, John, Succ.-Estole.\t75 acres.\tS.P.4.3.\t4.\tt 11.64 20.09 12.52 12.62 12.39\t$ 35.65 52.36 24.18 24.18 24.20\tI 15.67 18.69 14.40 14.40 14.39\t$ 62.96 91.14 51.10 51.10 50.98 \t\t\t4.\t\t\t\t Kluke, Paul, Suas.-Estate.\t50 acres.\t6B-6C.\t6.\t\t\t\t Kluke, Paul, Succ.-£stat«.\t50 acres.\t7A.\t6,.,\t\t\t\t Kluke, Paul, Sacc.-Eetate.\t50 acres.\tS'A 8.\t6____\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Canton de Leslie \u2014 Township of Leslie Clermont, Berthold.Collins, Mrs.Ruth.Collins, Mrs.Ruth.Collins, Mrs.Ruth.Forsyth, Alexander.Jones, Philip M.C.Mayhew, Ross.Presley, Elwood.Routhier, Jean-Guy Routhier, Jean-Guy Routhier, Jean-Guy St-Pierre, Joseph .St-Pierre, Joseph.St-Pierre, Joseph.Trottier, Roger.^ acre plus ou moins / more or less 66 acres.67 acres.67 acres.\\i acre.\\i acre.35 acres.Bâtisse seulement sur lot / Bldg.only on lot 50 acres.50 acres.23 acres.72' x 150' .K acre.50 acres.M acre .P.24.P.24.P.25.P.26.P.38.28.S.P.39.32.S.P.21.S.P.22.S.P.23.P.32.P.32.S.P.8.P.38.3.3.3.3.C.3.2.4.4.4.2.2.A.3.$ 8.87 7.27 7.27 7.27 46.78 8.87 8.87 162.08 10.95 10.95 134.50 41.81 17.92 8.87 36.03 6.70 26.38 26.38 26.40 112.14 26.85 16.39 115.86 25.28 25.28 312.23 67.59 29.66 29.66 114.24 S 11.87 14.04 14.04 14.04 29.07 14.29 13.03 43.35 14.35 14.35 63.61 23.13 15.71 14.62 28.03 Canton de Litchfield \u2014 Township of Litchfield Barette, Mrs.Rose.Beckstead, John .Becksyead, John .Carron, Aurelle.Dumoulin, Gaston.Lawn Bros.Lawn Bros.Lawn Bros.Lawn Bros.Lawn Bros.Ranger, Succ.-Estate Edward.Ranger, Succ.-Estate Edward.Pavia, Robert.Pavia, Robert.Subdivision non officielle No 76A Non-official subdiv.No.76A Subdivision non officielle No 26 Non-official subdivision No.26 Subdivision non officielle No 27 Non-official subdivision No.27 Subdivision non officielle No 1 Non-official subdivision No.1 Subdivision non officielle No 2 Non-official subdivision No.2 P.28A.P.28.P.28.P.20A.P.25B.17A.17B.18B.19B.25A.14.18.P.28.P.28.7.\tt 57.10\t% 164.64\tS 36.61\t( 258.35 7.\t47.89\t135.54\t32.01\t215.44 7.\t8.93\t\t11.07\t20.00 11.\t56.82\t101.59\t29.00\t187.41 11.\t6.83\t92.88\t21.96\t121.67 8.\t14.95\t38.10\t16.37\t69.42 \t15.18\t38.77\t16.47\t70.42 8.\t14.95\t38.10\t16.37\t69.42 8.\t15.18\t38.82\t16.48\t70.48 10.\t11.72\t28.24\t14.80\t54.76 8.\t69.38\t172.07\t38.97\t280.42 8 .\t27.34\t88.51\t23.90\t139.75 7.\t49.05\t138.62\t32.52\t220.19 7.\t10.98\t34.65\t15.48\t61.11 \t\t\t\t 2170 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1971,, Vol.106, No.11 Commission scolaire protestantes de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board Nom sur rôle Name on roll\tSuperficies Area\tNo du lot Ijot No.\tRang Range\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \tSubdivision non ofiîcielle No 28 Non-official subdivision No.28\tP.28.\t7.\t\t$ 15.60\t$ 11.87\t$ 27.47 \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board\t\t\t\t\t\t\t \t\tP.28B.\t\t\tS 56.60\t$ 16.79\t$ 73.39 \t\t\t\t\t\t\t Ecole municipal de Portage du Fort \u2014 School Municipal of Portage du Fort\t\t\t\t\t\t\t Bigras, Patrick et/ou and/or Kevin Coyne\tSubdivision 58.\t25.\t1.\t\t$1,018.37\t$132.20\t$ 1.150.57 Canton de Mansfield \u2014 Township of Mansfield \t\t27-25 .\t2\t$58.00 133.00 1.50 230.00 32.50 4.00 40.00\t$ 129.84 45.35 56.64 58.85 4.50 26.66\t$ 32.54 31.40 10.18 44.40 20.96 11.02 18.00\t$ 220.38 209.75 11.68 331.04 112.31 19.52 84.66 \t\tP.13-7\t1\t\t\t\t \t\tP.17-7.\t1.1\t\t\t\t \t\tP.13-18\t\t\t\t\t \t\tP.24.\t3\t\t\t\t \t\tP.23.\t3.\t\t\t\t \t\tP.35.\t2.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board\t\t\t\t\t\t\t \t\tP.21\t1\t\tS 108.41 88.41\t$ 23.00 21.61\t$ 131.41 110.02 \t\tP 22\t1\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Desjardins, François Succ.-Estate.Graveline, R.& Zarapora.Graveline, R.& Zampora.Graveline, R.& Zampora.Graveline, R.& Zampora.Malo, Hermidas.Vincent, Roger.P.13-42 5-1_____ P.3.P.4.P.6.P.13-23 P.11.1.A 2.2.2.1.6.$ 19.50 40.50 41.25 216.25 6.60 6.50 85.73 102.76 214.23 218.13 1,023.38 29.61 29.61 S 20.29 24.67 40.57 41.13 158.76 14.33 14.33 Canton de Pontefract \u2014 Township o/ Ponlefract \t\tP.11A-A\tA \t\tP 12\tA \t\tP 13\tA \t\t8A.\tA \t\tP.9\tA \t\tP.9\tA \t\tP 10\tA \t\tP.14B.\tA \t\t\t 66.00 66.00 30.00 30.00 15.00 89.00 40.00 48.00 114.77 114.77 64.32 31.40 15.71 94.24 41.87 8 31.69 31.69 20.12 17.37 13.69 31.99 19.82 15.76 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2171 Commission scolaire de Pontiac \u2014 Pontiac School Board Nom sur rôle Name on roll\tSuperficie Area\tNo du lot Lot No,\tRang Range\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tFrais Costs\tTotal \t\t44.\tB.\t$ 6.00 9.00 6.00\t$ 32.34 13.34 32.79\t$ 14.60 12.68 14.65\t8 52.94 35.02 53.44 \t\t46.\tB.\t\t\t\t Graveline, R.& Zampora.\t\t47.\tB\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Village de Portage du Fort \u2014 Village of Portage du Fort Cameron, Joseph.Cameron, Joseph.380 p.c.-s.f.1,000 p.c.-s.f.45.46.$150.21\t$ 93.04\t$ 39.19 1.76\t2.24\t10.48 Canton de Onslow North \u2014 Township of Onslow North Quyon Molybdenite Co.Thompson, Earl.Approx.37 acres 10,000 p.c.-s.f.10A.P.4A.7.\t8 4.80 8.\t8.53 \t 4.58 $ 11.13 11.02 Canton de Onslow South \u2014 Township of Onslow South Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board \t\t\t4.\t$ 34.98 159.64 11.82\t$ 18.94 186.51 29.74\t$ 16.47 61.64 14.99\t$ 70.39 397.69 66.55 \t\t17A.\t4.\t\t\t\t Stephen, Wallace.\t\tP.1A.\t4.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Village de Quyon \u2014 Village of Quyon\t\t\t\t\t\t\t \t30,000 p.c.-s.f.16,912 p.c.-«./.8,712 p.c.-s.f.13,000 p.c.-s.f.11,418 p.c.-s.f.5,709 p.c.-s.f.\tP.310.t.\t3.\t$ 29.69 98.89 17.94 149.33 71.12 543.33\t$ 30.50 475.63 15.79 165.28 49.18 172.80\t$ 17.22 78.94 14.05 47.75 24.44 95.94\t$ 77.41 653.46 47.78 362.36 144.74 812.07 \t\t\t3.\t\t\t\t \t\tP.350.\t3.\t\t\t\t \t\tP.350.\t3.\t\t\t\t \t\t\t3.\t\t\t\t \t\tP.73.\t3.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Canton de Thorne \u2014 Township of Thome\t\t\t\t\t\t\t Holt, Eugène Succ.-Estate\t\t13B-14B.\t2.\t$ 23.18 5.31 43.14\t$ 44.02 28.33 92.48 54.32\t$ 18.06 .14.04 21.10 21.70\t8 85.26 47.68 113.58 119.16 Lapointe, Gerald, succ.-est.\t24,000 p.c.-s.f.Bâtisses seulement / With buildings\t15A.P.H.\t2.1.\t\t\t\t \t\tP.10.\t5.\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t Canton de Waltham \u2014 Township of Waltham Commission scolaire protestante de Pontiac \u2014 Pontiac Protestant School Board Hammel Edgar\t\t30-19.\t1.\t$ 14.82\t$ 99.48\t$ 23.72\t$ 138.02 \t\t\t\t\t\t\t Campbell's Bay, Québec, 20 février 1974.Le secrétaire-trésorier, 56355-10-2-o C.Robillard.Campbell's Bay, Québec, February 20, 1974.C.Robillard, 56355-10-2-o Secretary-Treasurer. 2172 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Corporation municipale du comté de Dorchester Avis public est par les présentes donné par Henri-Paul Bouffard, secrétaire-trésorier de la corporation municipale du comté de Dorchester que les immeubles ci-dessous décrits seront vendus à l'enchère publique, pour taxes municipales et/ou scolaires dues et les frais encourus, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MAI 1974, en la salle du conseil de comté, à Ste-Hénédine, à DIX heures de l'avant-midi.à moins que lesdites taxes et les frais aient été payés avant le jour ci-dessus indiqué.Municipal Corporation of Dorchester County Public notice is hereby given by Henri-Paul Bouffard, Secretary-Treasurer for the Municipal Corporation of Dorchester County, that the underdescribed immovables will be sold bv public auction for municipal and/or school taxes due and costs, THURSDAY the NINTH day of MAY 1974 in the Hall of the Council, in Ste-Hénédine at TEN o'clock in the morning, unless said taxes and costs be paid before the day above mentioned.Municipalité de St-Benjamin Morissette-Station \u2014 Municipality of St.Benjamin Morissette-Station Taxes Taxes Propriétaire Rang Canton munie.bcoI.Frais Lot Total Oirnrr Range Township Munie.School Costs taxes taxes Honorius Champagne.P.19D25.3 Watford.8 81.62 8 56.40 $138.02 Succession / Estate Superficie / area 60 x 120' avec bâtisse / with building Martin Poulin.P.10.E Watford.12.93 11.99 24.92 Sans titre / without title Municipalité de Ste-Germaine / Municipality of Ste.Germaine Joseph Pouliot (Fort).P.451.7 Superficie / area .20 sans titre / without title Mile Mance Roy.1/2 N.719.12 Superficie / area 52.63 Albert Gourde.p.323.5 Superficie / area 81.11 Gérard Nadeau.P.820.14 Superficie / area 111.38 Superficie I area 134.83 P.821.14 Distraire les parties vendues sur ces lots / to withdraw the parts sold on those lots Dominique Pépin.P.196.3 Succession / Estate Superficie / area 90.65 Distraire adjudication 3x7 acres To withdraw adjudication 3x7 acres Cramb.$ 129.24 $ 129.24 Cramb.27.31 27.31 Ware.541.92 541.92 Cramb.77.52 77.52 Cramb.Ware.$ 6.66 20.86 27.62 Municipalité de Ste-Justine \u2014 Municipality of Ste.Justine ^\"fCayouette .P.16-n.e.X Langevin.$ 65.65 $ 65.65 Superficie / area 83 acres Détenu sous billet de location / held under location ticket S,m^rfinAel/LaCho2Ce466.VI1 Ware.$ 32.00 48.42 80.42 Superficie / area 96 acres GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106- année, n° 11 2173 Municipalité de St-Louis de Gonzague \u2014 Municipality of St.Louis de Gonzague Taxes Taxes Propriétaire Rang Canton munie.scol.Frais Lot Total Owner Range Township Munie.School Costs taxes taxes Guy Gagnon.63A&63B.IV Langevin.$ 39.00 $ 21.39 $ 1.98 8 62.37 Superficie environ 46 acres avec S.O S.O.bâtisses Area about 46 acres with buildings .Philippe Simard.P.69.1-A Langevin.14.46 29.41 4.00 47.87 Adresse inconnue / unknow address Superficie / area 20 arpents Municipalité de St-Zacharie Paroisse \u2014 Municipality of St.Zacharie Parish Jules Daigle.22.Superficie / area 12 acres Coupe de bois / woodlot Henri Bisson.P.44 .Superficie / area, un / one emplacement Claude Laflamme.P.48.Superficie chalet et emplacement Area cottage and emplacement Maurice Gagné.P.31-A.Superficie / area 12000 piz-eo./(.Maison / house & garage Metgermette-Nord S 3.80 $ 1.80 8 2.32 $ 7.92 Metgermette-Nord 9.75 9.75 Metgermette-Nord 31.20 2.54 33.74 Metgermette-Nord 92.27 5.20 97.47 Municipalité de St-Zacharie Village \u2014 Municipality of St.Zacharie Village Léo Couture.P.31-A.6 Metgermette-Nord $211.19 $ 22.86 $ 234.05 Superficie / area 7,500 pi»-eg./(.Boulangerie bake-house & Sheds Donné à Ste-Hénédine, ce 25e jour de février 1974.Le secrétaire-trésorier, 56361-10-2-o Henbi-Paul Bouffard, c.m.c.d.Given at Ste.Hénédine this 25th day of February 1974.Henri-Paul Bouffard, m.c.c.d., 56361-10-2-o Secretary-Treasurer.Ville de Mirabel Avis est par les présentes donné par le soussigné greffier de la ville de Mirabel, que les propriétés immobilières ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère publique, JEUDI, le DIX-HUITIÈME jour d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi, à l'Hôtel de Ville de Mirabel, 312 rue St-Jacques, Stc-Scholas-tique, à défaut de paiement des taxes municipales et intérêts, et ainsi que les frais encourus.Town of Mirabel Notice is hereby given by the undersigned, city clerk of Mirabel, that the immovable properties hereunder described will be sold by public auction on THURSDAY, the EIGHTEENTH day of APRIL 1974, at TEN o'clock in the forenoon in the Town Hall of Mirabel, 312 St-Jacques Street, Ste-Scholastique, in default of payment of municipal taxes and interest, plus costs incurred. 2174 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Cadastre de la Paroisse de Saint-Jérôme \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Jérôme No Rôle Nom et adresse Description de l'immeuble Roll No.Name and address Description of immovable 01-101-47 Langer Charles.Lipman Isidore, Steinberg Harry 01-101-52 a/s /c/o: Hendler, Teddy, 1730 Hartensteins.Vi o) Une partie du lot 158, et une partie du lot 159.mesurant cesdites parties une superficie de 65 arpents, plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: Au nord-ouest par la route No 41, au nord-est par le lot No 160, au sud-est par partie du lot No 159 et par le chemin public traversant le lot No 158 et une partie du lot No 159 et au sud-ouest par le résidu du lot No 158 qui a été réservé par Jean Lamoureux, et par une autre partie du lot No 158 étant la propriété de Jean Plouffe (enrg.234,795).6) Le lot 161, ayant une superficie de 46 arpents, plus-ou moins, à distraire un emplacement mesurant cent pieds (100') de largeur par cent pieds (100'J de profondeur, ayant front sur la route No 41.La ligne sud-ouest de l'emplacement se trouvant à une distance de cent dix-sept pieds (117') de la ligne de division entre les lots Nos 160 et 161 et parallèle à ladite ligne.Hendler, Morrin Ile St-Laurent.(a) A part of lot 158, and a part of lot 159, having an area of 65 arpents, more or less, and bounded as follows, to wit: Towards the northwest by the public road No.41, towards the northeast by lot No.160, towards the southeast by part of lot No.159 and by public road crossing lot No.158 and part of lot No.159 and towards southwest by the residue of lot No.158 being reserve by Jean Lamoureux, and by another part of lot No.158 being the property of Mr.Jean-Paul Plouffe (Enrg.234.795).(6) The lot No.161 having an area of 46 arpenis, more or less, to distract a site measuring 100 feet in width by 100 feet in depth, and bounded in front by the public road No.41.The southwest line of the site being at 117 feet from the line separating the lots Nos.160 ana parallel to the said line.Cadastre de la Paroisse de Saint-Augustin \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Aunvslin 02-042-03 Thomson, Evelyn, 604 Petit Brûlé.St-Augustin, Mirabel, P.Q.55-4.02-109-11 Boucher, Conrad.11, 42e Ave.Bois des Filions, Terrebonne, P.Q.243-126.02-228-15 Antecol, Bennie, 4570 Notre-Dame O., Laval, P.Q.448-168 à / to 170 incl.02-245-03 Lechasseur, Eddy, 7535 Verdier, St-Léonard, P.Q.448-149 à / to 155 incl.02-269-04 Lechasseur, Eddy, 7535 Verdier.St-Léonard, P.Q.448-178 à / to 183 incl.02-271-02 Gyorkos.Steve.609 Bathurst, Toronto 4, Ontario.449-174.02-291-10 Boros, Peter.5891 Centennial Ave East.Côte St-Luc, Mtl.269, P.Q.450-18 a / to 20 incl.02-298-04 Lowsky, Sam, 24 Mont-Royal W., Suite 601, Montréal 14, P.Q.451-83 à / to 84 incl.02-313-21 Chartrand, Léona, Dame Vve, 42 Côte St-Louis, Ste-Thérèse, P.Q.463-48.02-334-02 Nepton, Roland, 3203 Paul #1, Montréal, P.Q.464-138.Cadastre de la Paroisse de Saint-Benoît \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Benoit 04-031-01 Ferrera Da Costa, Rogerio, Caracas, Venezuela.04-031-02 Ferrera Da Costa, Rogerio.Colle Reale de la Castoda.Caracas-Ven.04-031-03 Ferrera Da Costa, Rogerio, Colle Reale de la Castoda, Caracas-Ven.04-057-13 Dunn, Pat, 45 Boul.Dorval, a/s / c/o Dunn Richard, 402-2390 First Ave.W., Vancouver, British Colombia.04-066-16 Zulay, Alamo De Velutini, Avenida, Avila No 23, Quinta H-Z, Altimira, Caracas, Venezuela.04-141-20 Baryl.Mme / Mrs.Audrey et / and Johnson, William, Fabreville, P.Q.05-032-06 Thériault, Mme / Mrs.Andrée, St-Benolt Village, Mirable, P.Q.05-037-09 Sévigny, Joseph.58-44.58-24.58-25.62-79.62-218.196-1, 197-1, 201-1, 202-2, 203, 204-1.303-2.303-3.Cadastre de la Paroisse de Saint-Canut \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Canut 06-091-08 Aubin, Flore Anna.06-101-36 Domain Unie Inc., Montréal, P.Q.Une partie du lot 92 ayant une superficie de 12 arpents, plus ou moins, et borné comme suit: au nord par la rivière du nord, à l'autre bout par le trait carré des emplacements de la route No 41, savoir: Jean-Louis Robert, en ligne droite avec Cari Boileau, Antonio Robert, Wilfrid Dagenais, Gérard Rochon, Roger Robert, Fernand Lapointe, d'un côté par le lot No 91 et de l'autre par le lot No 93.à retrancher 3 emplacements.(Enrg.121,591).94-356.A part of lot 92 having an area of 12 arpents, more or less, and bounded as follows, towards the north by the North River, towards the other end by the line separating the said lot and the lots bounded by the public road No.41, to wit: Jean-Louis Robert, in straight line with Carl Boileau, Antonio Robort, Wilfrid Dagenais, Gérard Rochon, Roger Robert, Fernand Lapointe, towards one side by the lot No.91 and towards the other side by the lot No.93, to distract 3 lots.(Enrg.121.591). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, «\" U 2175 No Rôle RoU No.Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 06-126-06 Les entreprises Marcal.St-Canut, Mirabel, P.Q.91-82.06-127-07 Rondeau, André, 9621 Boul.Rivières des Prairies.92-97.06-133-03 Lapolice, Roland.1639 Westgate, Ville Jacques-Cartier, P.Q.92-31-1.06-135-05 Lacombe, Raymond.724, 74e Ave, Chomedey, Laval, P.Q.91-108.92-63.06-142-06 Hamel, Alfred.504 Ch.de la Bretagne, Pont-Viau.Ville Laval.93-21.06-146-14 Desbiens, Cyrille, 3984 Berri, Montréal, P.Q.93-44.06-171-06 Ralph W.Roach, a/s / c/o Pheaton Realties, Corp.Stein, Harry, c.a.94-50 et / and 60.1255 Phillip Square, Montreal, P.Q.06-172-11 Rasko, Peter J., a/s / c/o Belavista Estates, 345 Victoria Avenue, 94-82.Westmount, P.Q.06-178-10 Wise, Jim Ray.345 Ave Victoria, Westmount.Montréal.94-102.06-193-01 Melvin D.Kahn, c/o Belavista Estates, 345 Victoria Avenue, Westmount, 94-319.P.Q.06-266-12 A .T.Construction Inc.60 Forget, Ste-Thérèse de Blainville.241-3.06-281-01 Archambault, Marcel, 279 Boul.Gouin, Montréal, P.Q.247-1.Cadastre de la Paroisse de Saint-Hermas \u2014 Cadastre of the Parish of Sainl-Hermas 07-081-16 Labelle, Georges, 223 St-Charles, St-Hermas, Mirabel, P.Q.144-6.Cadastre de la Paroisse de Saint-Janvier \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Janvier 08-051-03 Thibault.Gérard, 111 rue St-Michel, St-Janvier de 08-121-32 Rensonnet, Victor et Uxor.123 Turcot, St-Janvier, 09-132-09 Degongre, Gilles, 197 rue Charles, St-Janvier, Mira Une partie du lot 281, mesurant 1,892 par 138 pieds plus ou moins, laquelle partie est bornée comme suit, savoir: en front, au sud-ouest, par une rue projetée: en arrière, au nord-est, par une autre partie dudit lot 281.appartenant à René Demers; d'un côté, au nord-ouest, par une autre partie dudit lot 281 et de l'autre côté, au sud-est par la ligne de division de la paroisse de St-Janvier et de la paroisse de Ste-Thércse.Blainville.P.Q.274-114.Mirabel.P.Q.263-43.bel, P.Q.281 P.A part of lot 281 measuring 1,892 feet in width by 138 feet in depth, more or less, and bounded in front, towards the southwest, by a projected street: in back, towards the northeast by another part of the said lot No.281 or René Demers, from one side, towards the northwest, by another part of the said lot and from the other side, towards the southeast by the line separating the parish of St.Janvier and the parish of Ste.Thérèse.09-132-14 Peter Sandor.170 Charles Est, St-Janvier, Mirabel.281 P.Une partie du lot 281 mesurant 100 pieds de largeur par une profondeur de 200 pieds, et plus ou moins, et borné au nord-ouest par le chemin public; au sud-est, et des côtés nord-est et sud-ouest par partie dudit lot, la ligne sud-ouest étant située à 103 pieds de la ligne sud-ouest de Etienne Fekete et a(.A part of lot 281 measuring 100 feet in width by 200 feet in depth, more or less, and bounded towards the northwest by the public road, towards the south-east, the northeast and the southwest by part of the said lot; the southwest line being to 103 feet from the line southwest of Etienne Febete & al's property.Cadastre de la Paroisse de Saint-Jérusalem \u2014 Cadastre of the Parish of Saint-Jêrusalem 13-011-16 Claing, Simone, 2039 Boul.Labelle, Lafontaine, P.Q.Une partie du lot 13 ayant une superficie de 7.5 arpents, plus ou moins, et borné en front, à l'ouest par le chemin public appelé « East Settlement », à l'est par une partie du même lot, propriété de Delphis Gauthier, au nord par une autre partie du même lot, propriété de James Dorion, et au sud par partie du même lot, propriété de Marcel Giroux.A part of lot 13 having an area of 7.5 arpents, more or less, and bounded in front, towards the west by the public road called \"East Settlement\", towards the east by, a part of the said lot, Delphis Gauthier's property, towards the north by another part of the said lot, James Dorion's property, and towards the south by a part of the same lot, Marcel Giroux's property.Donné à Mirabel, ce 15e jour de février 1974.56424-lO-2-o Le greffier, Claude Belisle.Given at Mirabel, this 15th day of February 1974.Claude Belisle, 56424-10-2-o City clerk. 2176 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Municipalité du comté d'Argenteuil Avis est par les\" présentes donné par Douglas R.Bradford, secrétaire-trésorier du conseil municipal du comté d'Argenteuil, que les lots ou parties de lots ci-après mentionnés seront vendus à l'enchère publique à la salle d'audience du palais en la ville de Lachute, dans ledit comté d'Argenteuil, endroit où le conseil de comté siège, JEUDI, le NEUVIÈME jour de MAI, mil neuf cent soixante-quatorze, (9 MAI 1974) à DIX heures de l'avant-midi, pour taxes municipales, scolaires et autres dettes dues aux municipalités ci-après mentionnées à moins que celles-ci ne me soient payées, ainsi que les frais encourus, avant le jour de la vente.Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard Rodolphe Côté, 633 Stuart, Outremont, Que.\u2014 Contrat 98985 juillet 1962.91.86 acres.Lot 5, Ptie Rang II.Un emplacement situé dans St-Adolphe d'Howard, formant partie du lot 5, dans le deuxième rang, canton Howard aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton.Cet emplacement comprend tout le terrain qui est situé au nord de la rivière et qui est borné comme suit: vers le sud par la rivière, vers l'est par le lot 5, rang 1, dudit canton Howard, vers le nord et vers l'ouest par d'autres parties dudit lot 5, rang II, la propriété de M.Bernard Brunet.Avec bâtisses dessus construites.Ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes et occultes, et que l'acquéreur a déclaré connaître.Taxes municipales: $173.60; taxes scolaires: $427.62; frais: $21.83.Total; S623.05.Léonil Biais, Montfort, Que \u2014Contrat 122578, février 1968.Lot 6 partie mesurant 350 pieds de largeur par 50 de profondeur, superficie 17,500 pieds carrés.Borné en front vers le sud par le chemin public conduisant de Morin Heights au Lac-des-Seize-îles; en arrière vers le nord par cette partie du lot 7, rang 2.Taxes municipales: $152.53; taxes scolaires: $642.99; frais: $35.54.Total: $831.06.Mme Noëlla Desbiens, 1710 Rochon, St-Laurent, Que.\u2014 Contrat 111403.Lot 24A, subdivision 9, rang II, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 8,585 pieds carrés.Taxes municipales: $99.31 ; taxes scolaires: $98.40; frais: $18.93.Total: $216.64.Mme Noëlla Desbiens, 1710 Rochon, St-Laurent, Que.\u2014 Contrat 104123.Lot 24A, subdivision 10, rang II, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,700 pieds carrés.Taxes municipales: $345.11; taxes scolaires: $423.55; frais: $65.07.Total: $833.73.Adolph-T.Schwackc, 7702 Stocke St., Huntington Park, Californie.\u2014 Contrat 117196.Municipality of the County of Argenteuil Public notice is hereby given by Douglas R.Bradford, secretary-treasurer of the Municipal Council of the County of Argenteuil, that the lots or parts of lots hereinafter mentioned will be sold by Public Auction in the Court Room of the Court House, in the City of Lachute, in the said County of Argenteuil, being the place where the sittings of the County Council are held, on THURSDAY the NINTH day of MAY, one thousand nine hundred and seventy-four, (MAY 9 1974) at TEN o'clock in the forenoon for municipal taxes, school taxes and other debts due to the Municipalities hereinafter mentioned unless the same are paid to me with all costs incurred before the day of the sale.Municipality of St.Adolphe d'Howard Rodolphe Coté, 633 Stuart, Outremont, Que.\u2014 Contract 98985, July 1962.91.86 acres.Lot 5, Pt.Range II.An emplacement located in St.Adolphe-d'Howard, forming part of lot 5, in the Second Range, Township of Howard, on the official plan and in the book of reference for the said Township.This emplacement includes all the piece of land located to the north of the river and which is bounded as follows: towards the south by the river, towards the east by lot 5, Range I, of said Township of Howrad, towards the north and towards the west by other parts of said lot 5, Range II, property of Mr.Bernard Brunet.With the buildings erected thereon.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or un-apparent servitudes, and which the purchaser declares to be to his knowledge.Municipal taxes $173.60; school taxes: $427.62; costs: $21.83.Total: $623.05.Léonil Biais, Montfort, Que.\u2014Contract 122578, February 1968.Lot 6, part, measuring 350 feet in width by 50 in depth, area of 17,500 square feet.Bounded in front towards the south by tie public road leading from Morin Heights to Lac-des-Seize-Iles; at the rear, towards the north, by this part of lot 7, Range 2.Municipal taxes: $152.53; school taxes: $642.99; costs: $35.54.Total: $831.06.Mrs.Noëlla Desbiens, 1710 Rochon, St.Laurent, Que.\u2014Contract 111403.Lot 24A, subdivision 9, Range U, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 8,585 square feet.Municipal taxes: $99.31; school taxes: $98.40; costs: $18.93.Total: $216.64.Mrs.Noëlla Desbiens, 1710 Rochon, St.Laurent, Que.\u2014 Contract 104123.Lot 24A, subdivision 10, Range II, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 7,700 square feet.Municipal taxes: $345.11; school taxes: $423.55; costs: $65.07.Total: $833.73.Adolph-T.Schwacke, 7702 Stocke St., Huntington Park, California.Contract 117196. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106- année, n° 11 2177 Lot 15, subdivision 67, rang III aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 11,719.Taxes municipales: $178.20; taxes scolaires: $440.80; frais: $81.99.Total: $700.99.Lakeside Estates Inc., 5630 Queen Mary Rd., Montreal, Que.\u2014 Lot 16, subdivision non officielle 214, rang III, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 15,000 pieds carrés.Taxes municipales: $60.03; taxes scolaires: $97.15; frais: $24.37.Total: $181.55.Bovhannes Kojoran, 5852 Jeanne Mance, Montreal, Que.\u2014 Contrat 97628.Lot 19, subdivision 6, rang IV, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil, Superficie 18,185 pieds carrés.Taxes municipales: $63.97; taxes scolaires: $35.08; frais: $22.83.Total: $121.88.Jacques Tremblay, 8170 Christophe-Colomb, app.24, Montréal, Que.\u2014 Contrat 131193.Lot 9, subdivision 53, rang VI, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 6,500 pieds carrés.Taxes municipales: $73.76; taxes scolaires: $111.60; frais: $33.47.Total: $218.83.Lucien Dagenais, 8316 Du Mail, Anjou, Que.\u2014 Contrat 142539.Lot 9, subdivision 62, rang VI, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,000 pieds carrés.Taxes municipales: $211.31; taxes scolaires: $299.41; frais: $80.59.Total: $591.31.Willie Manceau, 7068 Clark, Montréal, Que.\u2014 Contrat 115389.Lot 10, subdivision 171, rang VI aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 6,750 pieds carrés.Taxes municipales: $164.84; taxes scolaires: $229.76; frais: $54.26.Total: $448.86.Gilles Maheu, 3926 Berri, Montréal, Que.\u2014 Contrat 114903.Lot 10, subdivision 178, rang VI, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,705 pieds carrés.Taxes municipales: $142.56; taxes scolaires: $207.78; frais: $47.99.Total: $398.33.Irénée Doyon, 5130 St.Clothilde, Montréal, Que.\u2014 Contrat 130020.Lot 11, subdivision 96, rang VI, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 9,847 pieds carrés.Taxes municipales: $232,96; taxes scolaires: $445.14; frais: $46.57.Total: $724.67.Reginald Santerre, 3692 Notre-Dame, Laval, Que.\u2014 Contrat 110375.Lot 11, subdivision 101, rang VI, aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 10,554 pieds carrés.Taxes municipales: $117.15; taxes scolaires: $92.46; frais: $25.13.Total: $234.74.Lot 15, subdivision 67, Range LU on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 11,719 square feet.Municipal taxes: $178.20; school taxes: $440.80; costs: $81.99.Total: $700.99.Lakeside Estates Inc., 5630 Queen Mary Rd., Montreal, Que.Lot 16, non official subdivision 214, Range III.on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 15,000 square feet.Municipal taxes: $60.03; school taxes: $97.15; costs: $24.37.Total: $181.55.Bovhannes Kojoran, 5852 Jeanne-Mance, Montreal, Que.\u2014 Contract 97628.Lot 19, subdivision 6, Range IV, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 18,185 square feet.Municipal taxes: $63.97; school taxes: $35.08; costs: $22.83.Total: $121.88.Jacques Tremblay, 8170 Christophe-Colomb, Apt.24, Montreal, Que.\u2014 Contract 131193.Lot 9, subdivision 53, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 6,500 square feet.Municipal taxes: $73.76; school taxes: SI 11.60; costs: $33.47.Total: $218.83.Lucien Dagenais, 8316 Du Mail, Anjou, Que.\u2014 Contract 142539.Lot 9, subdivision 62, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 7,000 square feet.Municipal'taxes: $211.31; school taxes: $299.41; costs: $80.59.Total: $591.31.Willie Manceau, 7068 Clark, Montreal, Que.-contract 115389.Lot 10, subdivision 171, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 6,750 square feet.Municipal taxes: $164.84; School taxes: $229.76; costs: $54.26; total: $448.86.Gilles Maheu, 3926 Berri, Montreal, Que-Contract 114903.Lot 10, subdivision 178, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 7,705 square feet.Municipal taxes: $142.56; school taxes: $207.78 costs: $47.99.Total: $398.33.Irénée Doyon, 5130 St.Clothilde, Montreal, Qué.-Contract 130020.Lot 11, subdivision 96, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 9,847 square feet.Municipal taxes: $232.96; school taxes: $445.14 costs: $46.57.Total: $724.67.Réginal Santerre, 3692 Notre-Dame, Laval, Qué.-Contract 110375.Lot 11, subdivision 101, Range VI, on the official plan and in the book of reference for the Township of Howard, County of Argenteuil.Area of 10,554 square feet.Municipal taxes: $117.15; school taxes: $92.46; costs: $25.13.Total: $234.74. 2178 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Jean-Claude St.Jean, 10871 Salk, Montreal Nord, Que.\u2014Contrat 134627.Lot 12.subdivision 53, rang VI.aux plan et livre de renvoi officiel du canton Howard, comté d'Argenteuil.Superficie 7,875 pieds carrés.Tax'\u2022 faisant partie du lot numéro mille tivnte- deux (Ptie 1032), mesurant cent soixante-dix-sepl pieds de largeur (en avant) et cent trente pieds (de largeur) à l'arrière, sur une profondeur de deux cents pieds (177 x 130 x 200); borné à l'est par le chemin public, à l'ouest par la partie vendue au révérend W.B.Rosbo-rough.au sud par le ruisseau Munro et au nord par une partie du même lot appartenant à Mlle Prézeau, avec les bâtiments dessus érigés.La présente vente comprend tout le terrain additionnel, maintenant submergée par un lac artificiel, et acquise de Charles Hall suivant un acte en date du 30e jour d'août 1932, passé devant le notaire soussigné et enregistré à Argenteuil sous le numéro 45501.Tel que le tout existe présentement avec les servitudes pouvant s'y rattacher.À distraire dudit emplacement la partie vendu à Mme Madeleine Lcborgne, épouse de Marcel Noël, et enregistrée au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil sous le numéro 56955.Taxes municipales: $11.23; taxes scolaires: $31.17.Total: $42.40.Henry Nahass, 4 Fairview Court, Park Ridge, N.-J.> E.-U.\u2014 Lot No 1054-61.Le lot numéro soixante et un de la subdivision du lot originaire numéro mille cinquante-quatre (1054-61) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Chatham.Taxes municipales: $12.91; taxes scolaires: $29.01.Total: $41.92.La corporation municipale du canton de Wentworth Gaston Bourdage, adresse inconnue.\u2014 Lot.No 1A-42, 1B-24, rang 3.Un certain terrain connu (t désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un A (1A-42) et le lot numéro vingt-quatre (24) du lot originaire numéro un B (1B-24) rang 3.Sans bâtiments.Taxes municipales: $17.33.Gabriel Brodeur, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-8, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro huit (8) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Sans bâtiments.Taxes municipales: $24.71.André Bcrlhiaume, 99 Berge A Robert, Ste-Thcrèse-de-Blainville.\u2014 Lot No 1A-75, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-quinze (75) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un A, rang 3.Sans bâtiments.Taxes municipales: $17.33.Miss Lilian E.Jensen, unknown address.\u2014 Lot No.Pt.1032.A piece of land situate at Dalesville known and designated on the official plan and in the book of reference of the Township of Chatham, as forming part of lot number one thousand and thirty-two (Pt.1032) measuring one hundred and seventy-seven feet in front and one hundred and thirty feet in rear, by two hundred feet in depth (177' x 130' x 200') bounded cast by the public road, west by the portion sold to Rev.W.B.Rosborough, south by Munro's Creek and north by a part of the same lot belonging to Miss Prézeau with the buildings thereon erected.The present sale comprises all additional land now flooded under an artificial Lake, which was acquired from Charles Hall by a deed bearing date and passed before the undersigned notary the 30th of August 1932, and registered at Argenteuil, under No.45501.As the whole now subsists with all the servitudes which may be attached.To withdraw from the said emplacement part sold to Mrs.Madeleine Leborgne wife of Marcel Noël, and registered to the registry office of the County of Argenteuil, under number 56955.Municipal taxes: $11.23; school taxes: $31.17.Total: $42.40.Henry Nahass, 4 Fairview Court, Park Ridge, N.J.U.S.A.\u2014 Lot No.1054-61.Lot number sixty-one of the subdivision of original lot number one thousand and fifty-four (1054-61) on the official plan and book of reference of the Township of Chatham.Municipal taxes: $12.91; school taxes: $29.01.Total: $41.92.Municipal corporation of the Township of Wentworth Gaston Bourdage.unknown address.\u2014 Lot No.1A-42, 1B-24, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-two of the official subdivision of the original lot number one A (1A-42) and lot number twenty-four (24) of the original lot number one B (IB-24) Range 3.Without buildings.Municipal taxes: $17.33.Gabriel Brodeur, unknown address, Lot No.1B-8, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth.in the County of Argenteuil, as being the lot number eight (8) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", range 3.Without buildings.Municipal taxes: $24.71.André Berthiaume, 99 Berge A Robert, St.Thérèse-dc-Blainville.\u2014 Lot No.1A-75, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventy-five (75) of the official subdivision of the original lot number one A range 3.Without buildings.Municipal taxes: $17.33. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2183 Mme G.Rémillard-Daignault, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-24, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-quatre (24) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Sans bâtiments.Taxes municipales: $17.33.Succ.Séraphin Desmarais, 9028, 6e Avenue, Ville St-Michel.\u2014 Lot No 1A-85, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quatre-vingt-vinq (85) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $17.33; taxes scolaires: $4.50.Total: $21.83.Claude Douville.\u2014 Un emplacement connu et désigné comme faisant partie du lot originaire numéro un lettre « A », dans le Troisième Rang (Ptie 1-A, Rang LTI) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth division d'enregistrement d'Argenteuil; Borné ledit emplacement, en front, vers le nord-est, par une rue projetée de quarante pieds (40') de largeur, étant le lot (l-A-329 projeté), dudit canton de Wentworth, du côté sud-ouest, par la ligne de division des rangs II et III dudit canton de Wentworth, et de tous autres côtés, par des parties non subdivisées dudit lot 1-A, rang III, dudit canton de Wentworth; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes nord-est et sud-ouest, sur une profondeur de cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, formant une superficie totale de dix mille pieds carrés (10,000 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; La ligne sud-est dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des cantons de Gore et de Wentworth, et est située à une distance de cinq cent trente et un pieds (531') au nord-ouest de celle-ci; Cet emplacement porte les numéros trois cent sept et trois cent huit (Nos 307 et 308) sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a,c, en date du quatre août, mil neuf cent soixante-six, et portant le No C-6478.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit emplacement; Avec un camp d'été dessus à être construit par Lake-field Construction and Development Inc., et avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues communiquant audit emplacement, au lac et à la plage.Contrat No 122213.taxes municipales: $102.74; taxes scolaires: $56.25.Total: $158.99.Maurice Dufresne, addresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-25, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-cinq (25) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Sans bâtiments.Taxes municipales: $17.33.Mme.G.Rémillard Daigneault, unknown address.\u2014 Lot No.1A-24, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-four (24) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Without buildings.Municipal taxes: $17.33.Est.Séraphin Desmarais, 9028 - 6th Ave., Ville St.Michel \u2014 Lot No.1A-85, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number eighty-five (85) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $17.33; school taxes: $4.50.Total: $21.83.Claude Douville.\u2014 An emplacement known and described as forming part of original lot number one, letter \"A\", in the Third Range (Pt.1-A, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth, Argenteuil Registration Division.Said emplacement bounded in front, towards the northeast by a proposed street measuring forty feel (40') in width, being lot (l-A-329 proposed), of said Township of Wentworth, on the southwest side by the dividing line between RaDges II and III in said Township of Wentworth, and on all other sides by non-subdivided parts of said lot 1-A, Range III, of said Township of Wentworth; Measuring one hundred feet (100') in width, on its northeast and southwest lines, by one hundred feet (100') in depth on its northwest and southeast lines, covering a total area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft.), English measure, more or less; The southeast line of said emplacement is parallel to the dividing line between the Townships of Gore and Wentworth, and is located at a distance of five hundred thirty-one feet (531') to the northwest of the latter; Said emplacement is numbered three hundred seven and three hundred eight (Nos 307 & 308) on a proposed subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated August fourth, one thousand nine hundred sixty-six, and bearing number C-6478.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparent servitudes, attaching to said emplacement; With a summer camp to be constructed thereon by Lakefield Construction and Development Inc., and with a right of way with all others being entitled thereto, in the streets leading to said emplacement, to the lake and to the beach.Contract No.122213.Municipal taxes: $102.74; school taxes: $56.25.Total: $158.99.Maurice Dufresne, unknown address.\u2014 Lot No.1A-25, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being lot number twenty-five (25) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Without buildings.Municipal taxes.$17.33. 2184 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Mme Jeannette Figueira, 2969, Marlborough Court, Court, App.1, St-Laurent.\u2014Lot No 3-21-22, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt et un et vingt-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro trois, rang 3, (3-21-22, R.3).Avec bâtisse dessus construite.Taxes municipales: 8198.68; taxes scolaires: $43.56.Total : $242.24.Georges Grimaroi, 3275, de la Pépinière, Montréal.\u2014 Lot No 1A-44; 1B-44, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » ; et le lot numéro quarante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B » tous du rang 3.Sans bâtisse.Taxes municipales: $33.73.Donald Legault, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-16, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro seize (16) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B » (1B-16), rang 3.Sans bâtisses.Taxes municipales: $17.33.Wm.Moran, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-67, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un * A » (1A-67), rang 3.Taxes municipales: $17.33.Roger Pinard, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-30, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Artenteuil, comme étant le lot numéro trente (30) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un * B > (1B-30), rang 3.Taxes municipales.$17.33.Georges Quentin, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-38, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Artenteuil, comme étant le lot numéro trente-huit (38) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » (1A-38), rang 3.Taxes municipales: $17.33.Yvan Sirard.\u2014 Un emplacement situé dans le comté d'Argenteuil, connu et désigné comme étant composé d'une partie du lot originaire numéro deux, lettres «A», dans le Troisième Rang (Ptie 2-A, Rg.III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, division d enregistrement d'Argenteuil; Mesurant cent pieds (100') de largeur, dans ses lignes sud-ouest et nord-est, sur une profondeur de cent Mrs.Jeannette Figueira, 2969 Malborough Court, Apt.1, St.Laurent.\u2014Lot No.3-21-22, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-one and twenty-two (21-22) of the official subdivision of the original lot number three, range 3, (3-21-22, Rg.3).With building thereon erected.Municipal taxes: $198.68; school taxes: $43.56.Total: $242.24.Georges Grimaroi, 3275 de la Pépinière, Montréal.\u2014 Lot No.1A-44; 1B-44, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil as being the lot number forty-four (44) of the official subdivision of the original lot number one \"A\"; and lot number forty-four (44) of the official subdivision of the original lot number one \"B\" - all in range 3.Without buildings.Municipal taxes: $33.73.Donald Legault, unknown address.\u2014 Lot No.1B-16, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixteen (16) of the official subdivision of the original lot number one \"B\" (1B-16), range 3.Without buildings.Municipal taxes: $17.33.Wm.Moran, unknown address.\u2014 Lot No.1A-67, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-seven (67) of the official subdivision of the original lot number one \"A\".(1A-67), Range 3.Municipal taxes: $17.33.Roger Pinard, unknown address.\u2014 Lot No.1B-30, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty (30) of the official subdivision of the original lot number one \"B\".(1B-30), Range 3.Municipal taxes: $17.33.Georges Quentin, unknown address.\u2014 Lot No.1A-38, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil as being the lot number thirty-eight (38) of the official subdivision of the original lot number one \"A\".(1A-38, Rg.3).Municipal taxes: $17.33.Yvan Sirard.\u2014 An emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as consisting of one part of original lot number two, letter \"A',' in the Third Range (Pt.2-A, Rg.Ill), on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth, Argenteuil Registration Division; Measuring one hundred feet (100') in width, on its southwest and northeast lines by one hundred feet GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2185 pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, formant une superficie totale de dix mille pieds carrés (10,000 p.c-).mesure anglaise, plus ou moins: Borné en front, du côté sud-ouest, par une rue projetée (2-A-200 projeté) et de tous autres côtés, par d'autres parties dudit lot 2-A, rang ni, canton Wentworth; La ligne sud-ouest dudit emplacement est parallèle à la ligne de division des rangs II et III du canton de Wentworth et est située à une distance de cent quarante pieds (140') au nord-est de celle-ci ; La ligne sud-est dudit emplacement est perpendiculaire à la ligne de division des rangs II et III, canton Wentworth, et est située à une distance de mille cinq cent cinquante-quatre pieds et quatre-vingt-treize centièmes de pied (1,554.93') du point de rencontre entre les lignes de division des lots 11!, rang III, canton Wentworth, et 2-A, rang III.canton Wentworth, et des rangs II et III dudit canton, cette distance étant mesurée le long de la ligne de division des rangs II et III, dudit canton de Wentworth, en allant vers le sud-est; Cet emplacement porte le numéro cent quatre-vingt-dix (No 190) sur un plan de subdivision projetée, préparé par Leopold Moretti, a.g., en date du quinze juin, mil neuf cent soixante-six, et complété le dix-neuf avril, mil neuf cent soixante-huit, portant le No P.S.5389.Tel que le tout m trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées; Le tout sans bâtisse; Avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, aux lacs, à la piscine et aux plages, mais la ven-deresse ne sera pas tenue responsable d'aucun dommage pouvant découler à la suite d'accident survenu sur cesdits terrains.Taxes municipales: $17.33.Christian Tur, 5274 McKenna, Montréal, Que.\u2014 Un emplacement situé dans le comté d'Argenteuil connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro deux A dans le rang trois (Ptie 2A, Rg.ITI) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth division d'enregistrement d'Argenteuil.Borné vers le sud-ouest par une partie dudit lot 2A (rue des Marguerites) vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-est par d'autres parties dudit lot 2A; mesurant cent pieds (100.0') de largeur par cent pieds (100.0') de profondeur et contenant une superficie de 10,000 pieds carrés.Le coin sud-est de cet emplacement est situé à 21.47 pieds vers le nord-ouest de la ligne de division entre les lots Nos 2A et 1B dudit cadastre à partir d'un point situé à 140.14 pieds vers le nord-est de la ligne de division entre les raDgs II et III dudit canton.Cet emplacement porte les numéros de subdivision non-officielle 49 et 50 sur un plan-projet préparé par Leopold Moretti, a.g., en date du 4 août 1966 sous le numéro C-6478 de ses minutes et est ci-dessus décrit (100') in ddpth on its northwest and southeast lines, covering a total area of ten thousand square feet (10,000 sq.ft), English measure, more or less; Bounded in front, on the southwest side, by a proposed road (2-A-200 proposed) and on all other sides by other parts of said lot 2-A, Range III, Township of Wentworth; The southwest line of said emplacement is parallel to the dividing line between Ranges II and III of the Township of Wentworth, and is located at a distance of one hundred forty feet (140') to the northeast of the latter; the southeast line of said emplacement is perpendicular to the dividing line between Ranges II and III, Township of Wentworth, and is located at a distance of one thousand five hundred fifty-four and ninety-three hundredths feet (1,554.93') from the point of intersection between the dividing lines between lots 1-B, Range III, Township of Wentworth, and 2-A, Range III, Township of Wentworth, and Ranges II and III of said Township, such distance being measured along the dividing line between Ranges II and III, of said Township of Wentworth, in a southeasterly direction; Said emplacement is known as number one hundred ninety (No.190) on a proposed subdivision plan, prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated June fifteenth, one thousand nine hundred sixty-six, and completed on April nineteenth, one thousand nine hundred sixty-eight, bearing number P.S.5389.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching thereto; The whole without buildings; Subject to a right of way, with all others entitled thereto, in the proposed streets leading to said emplacement, to the lakes, to the pool and to the beaches, but the vendor shall not be held responsible for any damage ensuing from accidents that may occur on said land.Municipal taxes: $17.33.Christian Tur, 5274 McKenna, Montreal, Que.\u2014 An emplacement located in the County of Argenteuil, known and described as being a part of original lot number two \"A\" in Range Three (Pt 2A, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth, Argenteuil Registration Division.Bounded towards the southwest by a part of said lot 2A (Des Marguerites Street); towards the northwest and the northeast and the southeast by other parts of said lot 2A; measuring one hundred feet (100.0') in width by one hundred feet (100.0') in depth and covering an area of 10,000 square feet.The southeastern corner of said emplacement is located at a distance of 21.47 feet to the northwest of the dividing line between lots Nos.2A and IB of said cadastre, starting from a point located 140.14 feet to the northeast of the dividing line between Ranges II and III of said Township.Said emplacement bears non official subdivision Nos.49 and 50 on a draft-plan prepared by Leopold Moretti q.L.s., dated August 4, 1966.under number C-6478 of his minutes and is described hereinabove by said land- \u202221 Mi QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 par ledit arpenteur-goémètre en une description technique en date du 6 juillet 1971.Avec un droit de passage en commun dans les chemins privés pour communiquer dudit emplacement au chemin public.Taxes municipales: $17.33.Dame Irène Jacques, veuve de Louis Brisebois.\u2014 Un emplacement situé en la municipalité du Dunany, comté d'Argenteuil, faisant partie du lot originaire numéro deux, lettre « B », dans le Troisième Rang (Ptie 2-B, Rg.III) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, division d'enregistrement d'Argenteuil; Ledit emplacement étant de forme irrégulière et bornée comme suit: vers le sud, par une partie dudit lot 2-B (étant un chemin), vers le nord, par le lac Bixley, vers le nord-ouest et l'est, par d'autres parties dudit lot 2-B, rang III: Mesurant cent vingt-cinq pieds et quatre-vingt-sept centièmes de pied (125.87') en front, dans sa ligne sud; cent quatre-vingt-huit pieds et cinquante-huit centièmes de pied (188.58') dans sa ligne nord-ouest; cinquante-quatre pieds et quarante-cinq centièmes de pied (54.45') dans sa ligne nord (le long du lac): cent vingt-deux pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pied (122.85') dans sa ligne est; contenant une superficie de onze mille sept cent soixante-quatre pieds carrés (11,764 p.c), mesure anglaise, plus ou moins; Le coin nord-ouest de cet emplacement est situé à trois cent quarante pieds et seize centièmes de pied (340.16') vers le sud-est du lot No 3, et à quatre cent quatre-vingt-sept pieds et quatorze centièmes de pied (487.14') vers le nord-est du lot 2-A ; Le coin sud-ouest est situé à trois cent quarante pieds et soixante-treize centièmes de pied (340.73') vers le sud-est du lot No 3, et à deux cent quatre-vingt-dix-huit pieds et quarante centièmes de pied (298.40') vers le nord-est du lot No 2-A, du Troisième Rang, dudit canton; Cet emplacement porte le numéro deux (No 2), sur un plan de subdivision projetée préparé par I,éopoId Moretti, a.g., en date du vingt et un mai, mil neuf cent soixante-quatre; Tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, y attachées.Avec droit de passage avec tous autres y ayant droit, dans les rues projetées communiquant audit emplacement, au lac et à la plage; avec un camp d'été dessus érigé.Taxes municipales: $98.64.Marie Rose St-Louis.épouse de Roland Simard, adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-50, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro tin quante (50) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » (1A-50 Rg.3).Taxes municipales: $17.33.Lionel Trottier, 1540 Crevier, St-Laurent \u2014Lot No 1B-34, rang 3.surveyor, in a technical description, dated July 6, 1971.Subject to a common right of way on the private roads leading from said emplacement to the public road.Municipal taxes: $17.33.Mrs.Irène Jacques, widow of Louis Brisebois.\u2014 An emplacement located in the Municipality of Dunany, County of Argenteuil, forming part of original lot number two, letter \"B\", in the Third Range (Pt 2-B, R.Ill) on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth, Argenteuil Registration Division; Said emplacement being of irregular configuration and bounded as follows: towards the south by a part of said lot 2-B (being a road), towards the north by Lake Bixley, towards the northwest and the east by other parts of said lot 2-B, Range III; Measuring one hundred twenty-five and eighty-seven hundredths feet (125.87') in front, on its south line; one hundred eighty-eight and fifty-eight hundredths feet (188.58') on its northwest line; fifty-four and forty-five hundredths feet (54.45') on its north line (along the lake shore); one hundred twenty-two and eighty-five hundredths feet (122.85') on its east line; covering an area of eleven thousand seven hundred sixty-four square feet (11,764 sq.ft) English measure, more or less; The northwestern corner of said emplacement is located at a distance of three hundred forty and sixteen hundredths feet (340.16') to the southeast of lot No.3, and at a distance of four hundred eighty-seven and fourteen hundredths feet (487.14') to the northeast of lot 2-A; The southwestern corner is located at a distance of three hundred forty and seventy-three hundredths feet (340.73') to the southeast of lot No.3, and at two hundred ninety-eight and forty hundredths feet (298.40') to the northeast of lot No.2-A.in the Third Range of said Township; Said emplacement is known as number two (No.2), on a proposed subdivision plan prepared by Leopold Moretti, q.l.s., dated May twenty-first, one thousand nine hundred sixty-four; As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes, attaching thereto.Subject to a right of way with all others entitled thereto, in the proposed streets leading to the said emplacement, to the lake and to the beach; with a summer camp erected thereon.Municipal taxes: $98.64.Marie Rose St.Louis, wife of Roland Simard, unknown address.\u2014 Lot No.1A-50, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty (50) of the official subdivision of the original lot number one \"A\"; (1A-50 R.3).Municipal taxes: $17.33.Lionel Trottier, 1540 Crevicr, St.Laurent.\u2014Lot No.lB-34.Range3. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2187 Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-quatre (34) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $33.73.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-15, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quinze (15) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » (1A-15), rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc.; adresse inconnue Lot No 1A-16, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro seize de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-15, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quinze (15) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-17, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro dix-sept (17) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-19, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro dix-neuf (19) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-21, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt et un (21) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-22, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt- A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth in the County of Argenteuil as being the lot number thirty-four (34) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $33.73.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-15, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifteen (15) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", (1A-15) Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-16, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixteen (16) of the official subdivision of the original lot number one \"A\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.IB-15.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifteen (15) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-17, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number seventeen (17) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", R.3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.IB-19, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth.in the County of Argenteuil, as being the lot number nineteen (19) of the official subdivision of the original number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-21, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number twenty-one (21) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-22, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being 2188 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 deux (22) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-9, rang 3. Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro neuf (9) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $41.93.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-11, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro onze (11) de la subdivision officielle du lot originaire numéro un' B », rang.3.Taxes municipales: $27.17.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-33, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-28, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-35, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre île renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-cinq de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-36, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-37, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Ar-gentuil, comme étant le lot numéro trente-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales : $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue\u2014Lot No 1A-26, rang 3.the lot number twenty-two (22) on the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range o.Municipal taxes : $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-9, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number nine (9) of the official subdivision of the original lot number one \"B\", range ?.Municipal taxes: $41.93.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-11, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number eleven (11) of the official subdivision of the original lot number one 'B ', range 3.Municipal taxes: $27.17.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-33, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-28, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-eight of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-35, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil as being the lot number thirty-five of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-36.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-37, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-seven of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-26, Range 3. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° Il 2189 Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-39, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-23, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-trois de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-40, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-27, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lB-29,rang3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro vingt-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No lB-31,ring3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-32, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro trente-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-six of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-39, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth.in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-nine of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-23, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\" range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-40, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-27, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-29, Range 3.A certain piece of land know, and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number twenty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.lB-31,Range3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-one, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes : $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-32, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number thirty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85. 2190 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-53, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-trois, de la subdivision officielle du lot originaire numéro un «A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-56, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-57, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-59, rang 3.Un certain terrain connu et designé aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro cinquante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-60, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-48, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-47, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-46, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le Grace Park Inv.Inc., unknown address \u2014 Lot No.1A-53, Range 3.A certain piece of land known and designated on the of the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-three, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.IA-56, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-57, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-59, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number fifty-nine, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-60, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-48, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-47, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-seven, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-46, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106- année, n' 11 2191 comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-61.rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: 85.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-62, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1A-64; 1B-46, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro soixante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « A » ; et le lot numéro quarante-six de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-47, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-48, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-42, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante-deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Grace Park Inv.Inc., adresse inconnue.\u2014 Lot No 1B-41, rang 3.Un certain terrain connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth, dans le comté d'Argenteuil, comme étant le lot numéro quarante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro un « B », rang 3.Taxes municipales: $5.85.Wentworth.in the County of Argenteuil.as being the lot number forty-six, of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-61.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number sixty-one of the official subdivision of the original lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc.unknown address.\u2014 Lot No.IA-62, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number sixty-two, of the official subdivision of Unoriginal lot number one \"A\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1A-64; 1B-46, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number sixty-four of the official subdivision of the original lot number one \"A\"; and lot number forty-six of the official subdivision of the original lot number one \"B\".Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-47, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-scvan, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc.unknown address.\u2014 Lot No.1B-48, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil, as being the lot number forty-eight, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Paik Inv.Inc.unknown address.\u2014 Lot No.1B-42.Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth, in the County of Argenteuil.as being the lot number forty-two, of the official subdivision of the original lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85.Grace Park Inv.Inc., unknown address.\u2014 Lot No.1B-41, Range 3.A certain piece of land known and designated on the official plan and book of reference of the Township of Wentworth.in the County of Argenteuil.as being the lot number forty-one, of the official subdivision of Unoriginal lot number one \"B\", Range 3.Municipal taxes: $5.85. 2192 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- i des compagnies, et ayant son siège social dans la cité de Montreal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province pour obtenir l'autorisation d'abandonner sa charte, selon les stipulations de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, Québec, ce 28 février 1974.Le procureur de la compagnie.Monroe Abbey, c.r.4115, rue Sherbrooke ouest, Montréal, Québec.56492-o 1227 DRUMMOND STREET INC.Notice is hereby given that \"1227 DRUMMOND STREET INC.\", incorporated under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal.Québec, this 28th day of February, 1974.Monroe Abbey, q.c.Attorney for the Company.4115 Sherbrooke Street West, Montreal, Québec.56492-o POITRAS & POITRAS INC.Avis est donné que la compagnie « POITRAS & POITRAS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.St-Hyacinthe, le 22 février 1974.Le procureur de la compagnie.56493-0 Jean-Pierre Bousquet.POITRAS & POITRAS INC.Notice is given that \"POITRAS & POITRAS INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.St-Hyacinthe, February 22, 1974.Jean-Pierre Boi'squet, 56493-0 Attorney for the Company. 2226 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106.No.11 ROLIN CONSTRUCTION INC.Prenez avis que la compagnie.« ROLIN CONSTRUCTION INC.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Richard Tiiivierge.71, rue St-Pierrc, Québec, Que., G1K-7A9 56494-o ROLIN CONSTRUCTION INC.Notice is hereby given that \"ROLIN CONSTRUCTION INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me Richard Thivierge, Attorney for the Company.71 St.Pierre Street, Québec, (Que.), G1K-7A9 56494-o MARCEL POIRIER INC.Prenez avis que demande sera faite en vertu de la Loi des compagnies par « MARCEL POIRIER INC.»,420, St-Simon, Ste-Madeleine, (P.Q.), pour l'acceptation de l'abandon de sa charte.La secrétaire, 56522-0 Marie-Paule G.Poirier.MARCEL POIRIER INC.Notice is hereby given that \"MARCEL POIRIER INC.\", 420 St.Simon, Ste.Madeleine, P.Q., will apply for leave to surrender its charter, pursuant the Companies Act.Marie-Paule G.Poirier, 56522 Secretary.BROSSARD AVIATION AND MARINA LTD.BROSSARD AVIATION ET MARINA LTEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « BROSSARD AVIATION AND MARINA LTD.\u2014 BROSSARD AVIATION ET MARINA LTEE», corps politique incorporé suivant la I-oi des compagnies et ayant son siège social dans la Ville de St-Lambert, à li.'iô Mcrcille, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 25e jour de février, 1974.La secretaire.56536-o Anne Maria Ole.BROSSARD AVIATION AND MARINA LTD.BROSSARD AVIATION ET MARINA LTEE Notice is hereby given that \"BROSSARD AVIATION AND MARINA LTD.\u2014 BROSSARD AVIATION ET MARINA LTEE\", a corporation incorporated under the Companies Act, and having its head office in the City of St.Lambert at 635 Merci lie Avenue, District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 25th day of February 1974.Anne Maria Ole, 56536-o Secretary.Divers Compagnies Miscellaneous Companies BEAVER FOUNDATIONS LIMITED La compagnie « BEAVER FOUNDATIONS LIMITED » donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 4 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Russel C.Scrim.56457 4270-63 FONDATION PERE JEAN INC.FATHER JEAN FOUNDATION INC.La compagnie « FONDATION PERE JEAN INC.\u2014 FATHER JEAN FOUNDATION INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 5 à 9 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Eugène Kruk.56459 730381 BEAVER FOUNDATIONS LIMITED Notice is given that \"BEAVER FOUNDATIONS LIMITED\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Russel C.Scrim, Secretary.56457-0 4270-63 FONDATION PERE JEAN INC.FATHER JEAN FOUNDATION INC.Notice is given that \"FONDATION PERE JEAN INC.\u2014 FATHER JEAN FOUNDATION INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 9.56459-0 Eugène Kruk, Secretary.730381 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars Mi, 106' année, n° U 2227 D AIGLE & PAUL LIMITEE \u2014 LIMITED La compagnie « DAIGLE & PAUL LIMITEE \u2014 LIMITED » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 6.Le secrétaire, Jean Robert.56458-0 473-24 Ô645S DAIGLE & PAUL LIMITEE \u2014 LIMITED Notice is given that \"DAIGLE & PAUL LIMITEE \u2014 LIMITED\" has changed the number of its directors from 5 to 6.Jean Robert, Secretary.473-24 IMMEUBLES GAUBAU LIMITEE La compagnie «IMMEUBLES GAUBAU LIMITEE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le secrétaire, Robert Beaudry.56460-o 3573-63 IMMEUBLES GAUBAU LIMITEE Notice is given that \"IMMEUBLES GAUBAU LIMITEE\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Robert Beaudry, Secretary.56460 3573-63 INTERNATIONAL VIDEO CASSETTE SYSTEMS INC.La compagnie « INTERNATIONAL VIDEO CASSETTE SYSTEMS INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 4 à 7 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, S.Fedder.56461 2869-71 INTERNATIONAL VIDEO CASSETTE SYSTEMS INC.Notice is given that \"INTERNATIONAL VIDEO CASSETTE SYSTEMS INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 7.S.Fedder, Secretary- Treasurer.56461-0 2869-71 NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED La compagnie « NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE \u2014 NESBITT.THOMSON AND COMPANY.LIMITED » donne avis qu'elle a augmenté de 25 à 30 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire-trésorier, K.W.McArthur.56462 5149-52 NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE, LIMITEE NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED Notice is given that \"NESBITT, THOMSON ET COMPAGNIE.LIMITEE \u2014 NESBITT, THOMSON AND COMPANY, LIMITED\" has changed the number of its directors from 25 to 30.K.W.McArthur, Secretary-Treasurer.56462-0 5149-52 PRODUITS RECREATIFS LAURENTIDES INC.LAURENTIDE RECREATIVE PRODUCTS INC.La compagnie « PRODUITS RECREATIFS LAURENTIDES INC.\u2014 LAURENTIDE RECREATIVE PRODUCTS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 5 à 3.Le président, Alain Préfontaine.56463-0 4168-64 PRODUITS RECREATIFS LAURENTIDES INC.LAURENTIDE RECREATIVE PRODUCTS INC.Notice is given that \"PRODUITS RECREATIFS LAURENTIDES INC.\u2014 LAURENTIDE RECREATIVE PRODUCTS INC.\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Alain Préfontaine, President.56463 4168-64 LAVIGUEUR ASSURANCE INC.La compagnie « LAVIGUEUR ASSURANCE INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 5.Le secrétaire, Pierre Larue.56464-0 10497-59 LAVIGUEUR ASSURANCE INC.Notice is given that \"LAVIGUEUR ASSURANCE INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 5.Pierre Larue, Secretary.56464 10497-59 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 197i, Vol.106.No.11 LES ECUSSONS GRAND PRIX INC.La compagnie « LES ECUSSONS GRAND PRIX INC.\" donne avis qu'elle a change le nombre de ses administrateurs de 3 à 4.Le secrétaire.Marc Bourgeois.56465-0 737006 J.E.POITRAS INC.La compagnie « J.E.POITRAS INC.» donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 4 à 9.La secrétaire, Paule Gauthier.56466-0 16916-59 LES PLACEMENTS COTANCENTE LTEE COTANGENT INVESTMENTS LTD.La compagnie « LES PLACEMENTS COTANCENTE LTEE \u2014 COTA NO EXT INVESTMENTS LTD.\" donne avis qu'elle a augmenté de 3 à 5 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Ben Saskin.56499 730544 INSTITUT DES TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS INCORPOREE La corporation « INSTITUT DES TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS INCORPOREE » donne avis qu'elle a changé le nombre de ses administrateurs de 6 à 13.Le secrétaire, Gilles Champagne.56528-0 1143-66 LEGARE FOUNDRY 1961 LIMITED La compagnie « LEGARE FOUNDRY 1961 LIMITED » donne avis qu'elle a diminué de 5 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Harry E.Grundy.56529 12395-61 MAXIME FOOTWEAR COMPANY INC.La compagnie « MAXIME FOOTWEAR COMPANY INC.» donne avis qu'elle a augmenté de 7 à 11 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, John K.Armstrong.56530 14095-59 TANGENT CONSTRUCTION LTD.La compagnie « TANGENT CONSTRUCTION LTD.» donne avis qu'elle a diminué de 4 à 3 le nombre de ses administrateurs.Le secrétaire, Seymour Lake.56531 721742 LES ECUSSONS GRAND PRIX INC.Notice is given that \"LES ECUSSONS GRAND PRIX INC.\" has changed the number of its directors from 3 to 4.Marc Bourgeois, Secretary.56465 737006 J.E.POITRAS INC.Notice is given that \"J.E.POITRAS INC.\" has changed the number of its directors from 4 to 9.Paule Gauthier, Secretary.56466 16916-59 LES PLACEMENTS COTANGENTE LTEE COTANGENT INVESTMENTS LTD.Notice is given that \"LES PLACEMENTS COTANGENTE LTEE \u2014 COTANGENT INVESTMENTS LTD.\" has changed the number of its directors from 3 to 5.Ben Saskin, Secretary.56499-o 730544 INSTITUT DES TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS INCORPOREE Notice is given that \"INSTITUT DES TECHNIQUES DES ASSOCIATIONS INCORPOREE\" has changed the number of its directors from 6 to 13.Gilles Champagne, Secretary.56528 1143-66 LEGARE FOUNDRY 1961 LIMITED Notice is given that \"LEGARE FOUNDRY 1961 LIMITED\" has changed the number of its directors from 5 to 3.Harry E.Grundy, Secretary.56529-0 12395-61 MAXIME FOOTWEAR COMPANY INC.Notice is given that \"MAXIME FOOTWEAR COMPANY INC.\" has changed the number of its directors from 7 to 11.John K.Armstrong, Secretary.56530-o 14095-59 TANGENT CONSTRUCTION INC.Notice is given that \"TANGENT CONSTRUCTION LTD.\" has changed the number of its directors from 4 to 3.Seymour Lake, Secretary.56531-0 721742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1G mars 1971,, 106' année, n° 11 2229 Sièges sociaux VILLA CHINOISE INC.Avis est donné que la compagnie « VILLA CHINOISE INC.», constituée en corporation suivant la première partie de la Loi des compagnies, en date du 30 juin 1971, a établi son siège social à Baie St-Paul, au numéro 12.rue de la Lumière, district de Saguenay.Donné à Sillery, ce 31e jour de janvier 1974.Le notaire, Gilbert Lord.56467-0 3533-71 LES COMPTOIRS D'ABITIBI INC.Avis est donné que la compagnie « LES COMPTOIRS D'AHITIBI INC.».constituée par lettres patentes en date du 18 octobre 1973 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au 7, rue Abitibi, Place Honaventure.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 4 mars 1974.Les procureurs de la compagnie, 56468-0 Brière, BoiVTN, Paquette et Beaulac.CONSTRUCTION A MURS SECS NORMAND & SYLVIO INC.NORMAND & SYLVIO DRY-WALL CONSTRUCTION INC.Avis est, par les présentes, donné que « CONSTRUCTION A MURS SECS NORMAND & SYLVIO INC.\u2014 NORMAND & SYLVIO DRY-WALL CONSTRUCTION INC.», constituée en corporation par lettres patentes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à St-Hubert, a établi son principal bureau au numéro 5485 Chemin Chambly, district de Montréal, province de Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Le président, 56469-0 Sylvio Friolet.LES DISTRIBUTEURS ESCOMPRI INC.Avis vous est donné que la compagnie « LES DISTRIBUTEURS ESCOMPRI INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 12 décembre 1973, a établi son siège social et sa principale place d'affaires à 124, rue Murray, à St-Bruno-de-Montar-ville, district de Montréal.Montréal, ce 5e jour de mars 1974.L'administrateur, 56471-o Luc Moreau.Head Offices VILLA CHINOISE INC.Notice is hereby given that \"VILLA CHINOISE INC.\", incorporated under Part I of the Companies Actby letters patent dated June 30, 1971 has established its head office in Baie St-Paul, at number 12, de la Lumière Street, district of Saguenay, Province of Québec.Given at Sillery, Québec, this 31th day of January 1974.Gilbert Lord, Notary.56467-0 3533-71 LES COMPTOIRS D'ABITIBI INC.Notice is hereby given that the \"LES COMPTOIRS D'ABITIBI INC.\", company incorporated by letters patent, on the 18th day of October, 1973, and having its head office in Montreal, has established its office at No.7, Abitibi St., Place Bonaventure.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this March 4th, 1974.Brière, Boivin, Paquette et Beaulac, 56468 Attorney for the company.CONSTRUCTION A MURS SECS NORMAND & SYLVIO INC.NORMAND & SYLVIO DRY-WALL CONSTRUCTION INC.Notice is hereby given that \"CONSTRUCTION A MURS SECS NORMAND & SYLVIO INC.\u2014 NORMAND & SYLVIO DRY-WALL CONSTRUCTION INC.\", incorporated by letters patent issued under the provisions of Part I of the Companies Act, and having its head office in St-Hubert, has established its head office at 5485 Chambly Road, district of Montreal, Province of Québec.From and after the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Sylvio Friolet, 56469-0 President.LES DISTRIBUTEURS ESCOMPRI INC.Notice is hereby given that \"LES DISTRIBUTEURS ESCOMPRI INC.\" company incorporated by letters patents dated December 12th 1973, has established his head office and principal place of business at 124, Murray Street, St-Bruno-de-Montarville, district de Montreal.Montreal, this 5th day of March.1974.Luc Moreau, 56471-0 Administrator. 2230 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, A'o.11 CONSTRUCTION ESSOR INC.Avis est donné que la compagnie « CONSTRUCTION ESSOR INC.» constituée en corporation par lettres patentes en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies, en date du 10 janvier 1974, a établi son siège social au numéro 375 de la nie Papillon, a Laval, district de Montréal.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Daté à Laval, ce 4 mars 1974.Le président, 56470-o O aston Arcand.ESSOR CONSTRUCTION INC.Notice is hereby given that \"ESSOR CONSTRUCTION INC.\" incorporated by letters patent under the provisions of Part I of the Companies Act, on the 10th of January 1974, has established its head office at number 375 Papillon Street, at Laval.District of Montreal.From and after the date of this notice, the said office will be considered by the Company as being its head office.Dated at Laval, this March 4th, 1974.Gaston Arcand, 56170-o President.LES ENTREPRISES BERENT INC.Avis est, par les présentes, donné que « LES ENTREPRISES BERENT INC.-, une compagnie formée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes émises le 28 septembre 1973, à son principal bureau d'affaires à 236 avenue Parent, Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne, province de Québec.Daté à Saint-Jérôme, ce 31 janvier 1974.(Sceau) La secrétaire, 56472-o Denise Beauchamp.LES ENTREPRISES BERENT INC.Notice is hereby given that \"LES ENTREPRISES BERENT INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act, by letters patent issued on September 28, 1973, has its principal business office at 236 Parent Avenue, St.Jérôme, in the County of Terrebonne, Province of Québec.Dated in St.Jérôme, this 31st January, 1974.(Seal) Denise Beauchamp, 56472-o Secretary.FONTAINE CHIPS RESTAURANT INC.RESTAURANT DE PATATES FRITES FONTAINE INC.La compagnie « FONTAINE CHIPS RESTAURANT.\u2014RESTAURANT DE PATATES FRITES FONTAINE INC.* donne avis qu'elle a changé son siège social de Pointe-aux-Trembles, au numéro 5515, rue Montsabré, Montréal.Le secrétaire, gérard L'hérault.56473-0 729337 FONTAINE CHIPS RESTAURANT INC.RESTAURANT DE PATATES FRITES FONTAINE INC.Notice is given that \"FONTAINE CHIPS RESTAURANT INC.\u2014 RESTAURANT DE PATATES FRITES FONTAINE INC.\" has transferred its head office from Pointe-aux-Trembles to 5515 Montsabré Street, Montreal.GÉRARD L'HÉRAULT, Secretary.56473 729337 NOMIS CORP.La compagnie « NOMIS CORP.» donne avis qu'elle a transféré son siège social du numéro 7401, boulevard Newman, Lasallc, au numéro 4581, 8e rue, Laval.La secrétaire, Anita Maislin.56475 723059 NOMIS CORP.Notice is given that \"NOMIS CORP.\" has transferred its head office from 7401 Newman Boulevard, Lasalle, to 4581-8th Street, Laval.Anita Maislin, Secretary.56475-0 723059 NOVACO LIMITEE NOVACO LIMITED La compagnie « NOVACO LIMITEE \u2014 NOVACO LIMITED » donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 1235, rue Bourgogne, Chambly, au numéro 3350, boulevard Laurier, Saint-Hubert.Le secrétaire, Camille Rathe.56476-0 2725-65 NOVACO LIMITEE NOVACO LIMITED Notice is given that \"NOVACO LIMITEE \u2014 NOVACO LIMITED\" has transferred its head office from 1235 Bourgogne Street, Chambly, to 3350 Laurier Boulevard, Saint-Hubert.Camille Rathe, Secretary.56476-0 2725-65 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n\" 11 2231 PISCINES VAL MAR LTEE VAL MAR SWIMMING POOLS LTD.La compagnie « PISCINES VAL MAR LTEE \u2014 VAL MAR SWIMMING POOLS LTD.» donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 2000, boulevard Labelle, Laval, au numéro 600, Curé Roivin, Sainte-Thérèse-Ouest.Le secrétaire, Serge Desrochers.56477-0 10580-62 SMOOD PRODUCTIONS INC.LES PRODUCTIONS SMOOD INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « SMOOD PRODUCTIONS INC.\u2014 LES PRODUCTIONS SMOOD INC.», constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes émises le 1er octobre 1973, a transféré son siège social du 4591, avenue Hingston, à N.D.G., district de Montréal au 4115, rue Sherbrooke dans la ville de Montréal.Montréal, le 30e jour de janvier 1974.(Sceau) Le secrétaire, 56478 Robert Yineberg.PISCINES VAL MAR LTEE VAL MAR SWIMMING POOLS LTD.Notice is given that \"PISCINES VAL MAR LTEE \u2014 VAL MAR SWIMMING POOLS LTD.\" has transferred its head office from 2000 Labelle Boulevard, Laval, to 600 Curé Boivin, Ste.Thérèse-West.Serge Desrochehs, Secretary.56477 10580-62 SMOOD PRODUCTIONS INC.LES PRODUCTIONS SMOOD INC.Notice is hereby given that \"SMOOD PRODUCTIONS INC., \u2014 LES PRODUCTIONS SMOOD INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated October 1st, 1973 has moved its head office from 4591 Hingston Avenue in N.D.G., District of Montreal to 4115 Sherbrooke Street in the City of Montreal.Montreal, this 30th day of January, 1974.(Seal) Robert Vineberg, 56478-o Secretary.SOCIETE DE GESTION FERMEND INC.Avis est donné que la compagnie « SOCIETE DE GESTION FERMEND INC.» constituée par lettres patentes en date du 11 septembre 1973 et ayant son siège social dans la ville de Montréal, a établi son bureau au 7, rue Abitibi Place Bonaventure.A compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 5 mars 1974.Les procureurs de la compagnie, 56479-0 Brière, Boivin Paquette & Beaulac.SOCIETE DE GESTION FERMEND INC.Notice is hereby given that the \"SOCIETE DE GESTION FERMEND INC.\" company incorporated by letters patent, on the 11th day of September, 1973, and having its head office in Montreal, has established its office at No.7, Abitibi St., Place Bonaventure.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this March 5th, 1974.Brière, Boivin, Paquette & Beaulac, 56479-0 Attorneys for the company.DYNINCO INC.Avis est donné que la compagnie « DYNINCO INC.» constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies en date du huitième jour de juillet 1968, et ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé au numéro 7490 de la rue Garnier, l'a transporté au numéro 3637 du boulevard Métropolitain Est, Suite 1601.Donné à Montréal, ce douzième jour de novembre 1973.Jacques Des Aulniers.56501-o 2954-1968 EXPANSION VINGT ANS INC.La compagnie « EXPANSION VINGT ANS INC.» donne avis qu'elle a changé son siège social de Longueuil, au numéro 451, rue St-Sulpice, Montréal.Le secrétaire, Michel Gosselin.56502-o 346-70 DYNINCO INC.Notice is given that \"DYNINCO INC.\".incorporated under the Companies Act on the eighth day of July 1968, and having its head office in the City of Montreal, where its office was located at 7490 Garnier Street, has transferred said office to 3637 Metropolitan Boulevard East, Suite 1601.Given at Montreal, this twelfth day of November, 1973.Jacques Des Aulniers.56501 2954-1968 EXPANSION VINGT ANS INC.Notice is given that \"EXPANSION VINGT ANS INC.\" has transferred its head office from Longueuil to 451 St.Sulpice Street, Montreal.Michel Gosselin, Secretary.56502 346-70 2232 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol- '06¦ No.11 ANDRE LACHAPELLE AUTO BODY INC.Avis est donné que la compagnie « ANDRE LACHAPELLE AUTO BODY INC *, constituée en corporation par lettres pa tan tes émises en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies datées du 17 août 1971, at ayant son siège social dans la ville de Montréal où elle avait son bureau situé au 2192 rue Nicolet, le transportera à partir du 1er janvier 1974 au numéro 2245 de la rue Rouen.À compter du 1er janvier 1974, ledit bureau sera considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal, ce 14e jour de décembre 1973.Le président, 56474-o André Lachapelle.ANDRE LACHAPELLE AUTO BODY INC.Notice is given that \"ANDRE LACHAPELLE AUTO BODY INC.\", incorporated by letters patent issued pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act on August 17, 1971, and having its head office in the City of Montreal where its office was located at 2192 Nicolet Street, will transfer said office to 2245 Rouen Street, effective from January 1, 1974.From January 1, 1974 the said office will be considered by the Company as being its head office.Dated in Montreal, this 14th day of December, 1973.André Lachapelle, 56474 President.BEUTEL, GOODMAN & COMPANY INC.BEUTEL, GOODMAN & COMPAGNIE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « BEUTEL, GOODMAN & COMPANY INC.\u2014 BEUTEL, GOODMAN & COMPAGNIE INC.- , constituée en corporation dans la province de Québec, par lettres patentes en date du 23 janvier 1974 et ayant son siège social à Westmount, district judiciaire de Montréal, a établi son bureau principal au 4141 ouest, rue Sherbrooke, à Westmount, Québec.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son bureau principal.Donné à Montréal, ce 27e jour de février 1974.I* président, 56524-0 Austin C.Beutel.BEUTEL.GOODMAN & COMPANY INC.BEUTEL, GOODMAN & COMPAGNIE INC.Notice is herebv given that \"BEUTEL, GOODMAN & COMPANY INC.\u2014 BEUTEL, GOODMAN & COMPAGNIE INC.\", is incorporated by letters patent dated January 23, 1974 issued pursuant to the provisions of Part I of the Companies Act of the Province of Québec, and having its head office in Westmount, the District of Montreal, has established its office at 4141 Sherbrooke Street West.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal, this 27th day of February, 1974.Austin C.Beutel, 56524 President.LES DISTRIBUTIONS G.Y.M.INC.Avis est donné que la compagnie « LES DISTRIBUTIONS G.Y.M.INC.», constituée en corporation par lettres patentes datées du 23 août 1973 a son siège social dans le district de Montréal, au 395 rue Dowd, Montréal.H2Z IB6.Le président, 56525-o Yves Ducal.LES DISTRIBUTIONS G.Y.M.INC.Notice is given that \"LES DISTRIBUTIONS G.Y.M.INC.\", incorporated under l'art I of the Companies Act by letters patent issued on August, 23th, 1973 has its head office in the District of Montreal, 395 Dowd St., Montreal.H2Z 1B6.Yves Ducal, 56525-o President.A.R.CAFETERIA INC.Avis est donné que la compagnie « A.R.CAFETERIA INC.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies.Statuts refondus, 1964, chapitre 271,.en date du 24 août 1970 et ayant son siège social dans la municipalité de Crab-tree et district de Joliette, où elle avait son bureau situé jusqu'aujourd'hui au numéro 14, 8e rue, Crabtree, l'a transporté au numéro 350 Chemin Ste-Marie dans la municipalité de Crabtree et district de Joliette.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Crabtree, ce 30c jour île janvier 1974.Le président, 56538-o André Ri vest.A.R.CAFETERIA INC.Notice is given that \"A.R.CAFETERIA INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 271, on August 24, 1970, and having its head office in the Municipality of Crabtree, in the District of Joliette, where its office was located until the present day at 14 - 8th Street Crab-tree, has transferred said office to 350 Ste.Marie Road, in the Municipality of Crabtree, in the District of Joliette.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given in Crabtree, this 30th day of January, 1974.André Rivest, 56538 President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n° 11 2233 PANDECOR INC.Avis est donné que la compagnie « PANDECOR INC.», constituée en corporation par lettres patentes en date du 25 septembre 1973 et ayant son siège social en la ville de Montréal-Nord, a établi son bureau au numéro 10795, rue Pigeon.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Montréal-Nord, ce 22e jour de novembre 1973.Le président, 56526-0 Maurice Coallier.PANDECOR INC.Notice is hereby given that \"PANDECOR INC.\", company incorporated by letters patent on September 25, 1973, and having its head office in Montreal-Nord, has established its office at 10795 Pigeon Street.From and after the date of this notice the said office shall be considered by the company as being the head office of the company.Dated at Montreal-Nord, this 22nd day of November 1973.Maurice Coallier, 56526-0 President.PROMOTIONS SANVEL INC.La compagnie « PROMOTIONS SANVEL INC.donne avis qu'elle a changé son siège social du numéro 877, Perrier, Brossard, au numéro 2182, Place Etienne Brûlé, Montréal.Le secrétaire, Johanne S.Gravel.56527-0 736946 PROMOTIONS SANVEL INC.Notice is given ihat \"PROMOTIONS SANVEL INC.\" has transferred itshead office from 877 Perrier.Brossard, to 2182 Place Etienne Brûlé, Montreal.56527-0 Johanne S.Gravel, Secretary.736946 DARAC INC.Avis est donné que la compagnie « DARAC INC.» constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies en date du 24e jour de janvier 1974, et ayant son siège social dans Ste-Marie-de-Beauce a établi son bureau sur la rue Kennedy.À compter de la date du présent avis, ledit bureau est considéré par la compagnie comme étant son siège social.Donné à Ste-Marie, ce Se jour de mars 1974.L'officier autorisé, 56539-0 Camil Darac.DARAC INC.Notice is given that \"DARAC INC.\" incorporated under Part I of the Companies Act, on January 24, 1974, and having its head office in Ste.Marie-de-Beauce has established its office on Kennedy Street.From the date of this notice, the said office shall be considered by the company as being its head office.Given at Ste.Marie, this 8th day of March, 1974.Camil Darac, 56539 Authorized Officer.Commission municipale du Quebec Quebec Municipal Commission Ville de Vanier Avis est par les présentes donné que, par décision du 5 mars 1974 rendue en conformité des dispositions de l'article 52 de la Loi de la Commission municipale (S.R.Q.1964, chapitre 170 et ses amendements), la Commission municipale du Québec a décrété que la municipalité de la ville de Vanier, autrefois la municipalité de la ville de Québec-Ouest, ne sera plus considérée en défaut aux termes de la section V de ladite loi, et qu'elle reprendra l'exercice de tous ses pouvoirs le 14 mars 1974.Québec, le 5 mars 1974.Le secrétaire, 56508-o Gaston Lamarre.Town of Vanier Notice is hereby given that, by a decision rendered by the Québec Municipal Commission on March 5, 1974 in accordance with the provisions of section 52 of the Municipal Commission Act (R.S.Q.1964, chapter 170 as amended), the Municipality of the Town of Vanier, formerly the Municipality of the Town of Québec West, will cease to be considered in default under the terms of Division V of the said Act, and will resume all its powers from March 14th 1974.Québec City, March 5, 1974.56508-o Gaston Lamarre, Secretary. 2234 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16.1974, Vol.106, No.11 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Arnold Gelbartowicz Avis est par les présentes donné que Arnold Gelbartowicz, demeurant au numéro 7513, chemin Euclide, Cité de Côte-Saint-I.uc, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom de Arnold Gelbartowicz en celui de Atnold Gilbert.Le 22 février 1974.L'avocat, 7053, chemin Côte-Saint-Luc.June Gagnon.Côte-Saint-Luc, P.Q.56279-10-2 Nathan Belinsky Avis est par les présentes donné que Nathan Belinsky, courtier d'assurance, demeurant au No 6211 Côte St-Luc, app.306, Hampstead, P.Q.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant ses nom et prénom en ceux de « James N.Bellin ».Montréal, ce 5 février 1974.Le procureur du requérant, 56327-10-2-o Guy Lacoste, notaire.Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron Avis est donné que Mademoiselle Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron, serveuse-hôtesse, demeurant à Longueuil, au numéro 99 rue Montarville, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret lui permettant de changer son nom de Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron en celui de Francine Devost.Longueuil, le 4 février 1974.Le notaire de la requérante, 56358-10-2-o André Chabot.Marie Berthe Alice Lebel Avis est donné que Marie Berthe Alice Lebel, ména-_ gère, épouse de Fernand Lachapelle, résidant et domi-' ciliée au 8075, rue Lafontaine, app.2, Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice de la province «le Québec, en vue d'obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Lucienne Lebel.Montréal, ce 1er mars 1974.Lea procureurs de la requérante, Johanne Gagnon Trudel, Hargreaves, Monette, 56427-10-2-o Trudfl & Leduc.Enny de Jongh Swemer Avis est donné que dame Enny de Jongh Swemer, domiciliée au 1808 rue Sherbrooke, Montréal, présentera au ministre de la justice une requête lui permettant de changer son nom en celui de Dyanne Brettshaw.56435-10-2-o Enny de Jongh Swemer.Change of name \u2014 Act Applications Arnold Gelbartowicz Notice is given that Arnold Gelbartowicz, residing at 7513 Euclid Road, City of Côte St.Luc, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name from Arnold Gelbartowicz to Arnold Gilbert.February 22, 1974.June Gagnon, 7053 Côte- St.Luc Road, Lawyer.Côte St.Luc, P.Q.56279-10-2-o Nathan Belinsky Notice is hereby given that Nathan Belinsky, insurance broker, residing at No.6211, Côte St.Luc, Apartment 306, Hampstead, P.Q., will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his given name and surname to James N.Bellin.Montreal, February 5, 1974.Guy Lacoste, Notary, 56327-10-2 Attorney for the Petitioner.Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron Notice is hereby given that Miss Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron, hostess, living at Longueuil, 99 Montarville Street, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for permission to change her name from Marie-Hélène Raymonde Carole Ferron to Fran-cine Devost.Longueuil, February 4, 1974.André Chabot, 56358-10-2-o Notary for the Applicant.Marie Berthe Alice Lebel Notice is hereby given that Marie Berthe Alice Lebel, housewife, wife of Fernand Lachapelle, residing and domiciled at 8075 Lafontaine Street, Apt.2, Montreal, district of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for a decree of the Lieutenant-Governor in Council, changing her name to Lucienne Lebel.Montreal, March 1st, 1974.Johanne Gagnon Trudel, Hargreaves, Monette, Trudel & Leduc, 56427-10-2-o Attorneys for the Applicant.Enny de Jongh Swemer Notice is hereby given that Mrs.Enny de Jongh Swemer, domiciled at 1808 Sherbrooke Street, Montreal, will apply to the Minister of Justice for an order changing her name to Dyanne Brettshaw.56435-10-2 Enny de Jongh Swemer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1G mars 1974, 106- année, n° 11 2235 Jacob Brodmann Avis est par les présentes donné que Jacob Brodmann, joaillier, résidant et domicilié au 4875 Duffcrin Road, Montréal, province de Québec, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec un décret changeant son nom en celui de Jacques Brodman.Montreal, le 21 février, 1974.Les procureurs du requérant, 56365-10-2-o Geoffrion & Prud'Homme.Jacob Brodmann Notice is hereby given that Jacob Brodmann.jeweller, residing and domiciled at 4875 Duffcrin Road, Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Jacques Brodman.Montreal, February 21, 1974.Geoffrion & Prud'Homme.56365-10-2 Attorneys for Applicant.Gerald Altrovilch Avis est donné par les présentes que Gerald Altro-vitch, pharmacien, résidant au numéro 787.100e Avenue, Chomedey, Laval, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Gerald Altrows; ledit changement de nom devant aussi s'appliquer à son épouse, née Aileen (également connue sous le nom de Eileen) Lerner, et à ses enfants Earl Ryan, Michael Richard, Eve, Dale et Kim, tous demeurant à la même adresse.Montréal, le 14 février.1974.Le procureur du requérant, 56364-10-2-o Lawrence Capelovitch.Gerald Altrovitch Notice is hereby given that Gerald Altrovitch, pharmacist, residing at 787.100th Avenue, Chomedey, Laval, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Gerald Altrows; said change of name shall also benefit his wife, née Aileen (also known Eileen) Lerner.and his children, Earl Ryan.Michael Richard, Eve, Dale and Kim, all of the same address.Montreal, February 14th, 1974.Lawrence Capelovitch, 56364-10-2-o Attorney for Petitioner.Léon Vahan Melemetdjian Avis est donné par les présentes que Léon Vahan Melemetdjian, chirurgien-dentiste, résidant au 8325, L'Acadie, Suite 403.à Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Léon Vahan Lemian, ledit nom servant à toutes fins que de droit.Montréal, le 21 février, 1974.Les procureurs du requérant.Valiquette, Blouin & 56366-10-2-o Kochenburcer.Léon Vahan Melemetdjian Notice is hereby given that, Léon Vahan Melemetdjian, dental surgeon, residing at 8325 L'Acadie, Suite 403, in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Léon Vahan Lemian, said name to be used for all legal purposes.Montreal, February 21, 1974.Valiquette, Blouin & Kochenburoer, 56366-10-2 Attorneys for applicant.Karl-Ludwig Arnold WoIIschlager Avis est donné que Karl-Ludwig Arnold WoIIschlager, parfois connu sous le nom de Karl-Ludwig Arnold Bruhn, étudiant, domicilié et résidant au numéro 3428, rue Peel, appartement 31, Montréal Centre Ouest, Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom de Karl-Ludwig Arnold WoIIschlager, en celui de Karl-Ludwig Arnold Bruhn.56453-11-2-0 Karl Wollschlager.Karl-Ludwig Arnold Wollschlager Notice is given that Karl-Ludwig Arnold Wollschlager, sometimes known under the name of Karl-Ludwig Arnold Bruhn.student, domiciled and residing at 3428 Peel Street, Apt.31, Central West Montreal.Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name of Karl-Ludwig Arnold Wollschlager, to that of, Karl-Ludwig Arnold Bruhn.56453-11-2 Karl Wollschlager.Christian Simard Prenez avis que Christian Simard, domicilié au 1635 Drucourt, app.3, Montreal, présentera au lieutenant-gouverneur en conseil une demande pour changer son nom en celui de « Christian Cloutier ».Germain Dumas, 56500-1 l-2-o atocal.Christian Simard Notice is hereby given that Christian Simard having his residence at 1635 Drucourt, Apt.3, Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his name in \"Christian Cloutier\".Germain Dumas, 56500-1 l-2-o lawyer. 2236 QVF.BEC OFFICIAI.GAZETTE.Marri, te, i!>7.',.Vol.106, No.il Elijah Resnikoff Avis est par les présentes donné que Elijah Resnikoff, importateur, 347 Avenue Lazard.Ville Mont-Royal, district de Montréal, Quél>ec.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin de changer son nom en celui de Allan Rayson.Montréal, le 14 février 1974.Le procureur du requérant.56452-11-2-0 H.Solomon, c.r.Elijah Resnikoff Notice is hereby given that Elijah Resnikoff.importer, 347 Lazard Avenue, Town of Mount Royal, District of Montreal, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name to Allan Rayson.Montreal, February 14th.1974.H.Solomon, q.c, 56452-1 l-2-o Attorney for Petitioner.Joseph-Edmond Côté Avis est par les présentes donné que Joseph-Edmond Côté, agent d'immeubles, domicilié et demeurant au 120 de la Croix, Aima, district de Roberval, s'adressera au ministre de la justice, pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Joseph-Edmond Vianney Côté.Ce décret n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Les procureurs du requérant, Harvey, Harvey, 56440-1 l-2-o Abud & Tremblay.Joseph-Edmond Côté Notice is hereby given that Joseph-Edmond Côté, real estate broker, domiciled and residing at 120 De la Croix, in Alma, District of Roberval, will apply to the Minister of Justice of Québec for an order changing his name to Joseph-Edmond Vianney Côté.This order shall not affect any person other than the applicant himself.Harvey.Harvey, Abi'd & Tremblay, 56440-11-2 Attorneys for the applicant.Harvi ' Sniatowsky Avis est par les présentes donné que Harvey Sniatowsky, auditeur, résidant à 10957 Ave.James Morrice dans les ville et district de Montréal, s'addressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Harvey Sands, ledit nom devant servir à toutes fins légales.Montréal.Québec, le 1 mars 1974.Le procureur du requérant.56441-1 l-2-o Monroe A.Charlap.Harvey Sniatowsky Notice is hereby given that Harvey Sniatowsky, Auditor, residing at 10957 James Morrice Avenue, in the city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Harvey Sands, the said name to serve for all legal purposes.Montreal, Québec, March 1st, 1974.Monroe A.Charlap, 56441-1 l-2-o Attorney for petitioner.Issie Socoransky Avis est donné que Issie Socoransky, résidant au 26, avenue Shorncliffe, Westmount, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Irving Rocke Ransen; ce changement de nom s'appliquera aussi à son épouse, née Dorothy Ann Zalkind, de la même adresse.Montréal, le 8 mars 1974.Le procureur du requérant.56516-1 l-2-o David Litner, c.r.Issie Socoransky Notice is hereby given that Issie Socoransky, residing at 26 Shorncliffe Avenue, Westmount, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to \"Irving Rocke Ransen\"; said change of name shall also benefit his wife, née Dorothy Ann Zalkind, of the same address.Montreal, March 8, 1974.David Litner, q.c, 56516-11-2-0 Attorney for the Applicant.Aurellus Dumais Prenez avis que Aurellus Dumais.époux de Marie Louise Francoeur.domicilié au No 60, rue Léonie, appartement No 3, à Repentigny, district de Montréal, a présenté une requête au ministre de la justice, pour changer son prénom an celui de Aurèle Dumais.Montréal, ce 28 février 1974.Les procureurs du requérant, 56548-1 l-2-o Renaud & boucher.Aurellus Dumais Notice is given that Aurellus Dumais, husband of Marie Louise Francoeur, domiciled at 60 Léonie Street, Apartment No.3, in Repentigny, District of Montreal, has applied to the Minister of Justice for an order changing his name to Aurèle Dumais.Montreal, February 28, 1974.Renaud & Boucher, 56548-1 l-2-o Attorneys for applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' 11 2237 Stephen I lam \\, iili Avis est donné que Stephen Hanewich, acheteur, de Verdun, district de Montréal, résidant au 1032, boul.Brown, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Stephen Henwick.Montréal, le 23 novembre 1973.Le procureur du requérant, 56549-11-2 Ralph A.Cohen.Stephen Hanewich Notice is hereby given that Stephen Hanewich, purchaser, of Verdun, District of Montreal, residing at 1032 Brown Blvd., will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name bo Stephen Henwick.Montreal, November 23, 1973.Ralph A.Cohen, 56549-11-2-0 Attorney for Applicant.Loi électorale du Quebec Québec Election Act Rapport sommaire de dépenses électorales du Parti Créditiste aux élections générales du 29 octobre 1973 Rapport déposé au bureau du président général des élections, le 6 mars 1974.2.Location de locaux.S 3,591.24 3.Services.19,201.11 4.Frais de voyage et louage de voi- tures.14.248.53 5.Articles fournis.aucun 6.Publicité.:.238,081.35 7.Créances contestées.1,836.00 Total: 8276,958.2.3 Agent officiel.56509-o Roger Charbonneau.Summary return of election expenses of the Creditiste Party at the general election of October 29, 1973 Return delivered to the office of the Chief Returning-Officer, on March 6, 1974.2.Hire of premises.S 3,591.24 3.Services.19,201.11 4.Travelling expenses and hire of vehicles.14,248.53 5.Goods supplied.nil 6.Advertising.23S.081.35 7.Disputed Claims.1,836.00 Total: $ 276,958.23 Roger Charbonneau, 56509-o Official Agent.Ministère des institutions\tDepartment of Financial financières, compagnies et\tInstitutions, Companies and coopératives\tCooperatives Compagnies de fidéicommis\tTrust Companies FIDUCIE PRET ET REVENU\tFIDUCIE PRET ET REVENU SAVINGS AND INVESTMENT TRUST\tSAVINGS AND INVESTMENT TRUST Avis d'enregistrement\tNotice of Registration Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies de fidéicommis, il a accordé à « FIDUCIE PRET ET REVENU \u2014SAVINGS AND INVESTMENT TRUST », compagnie constituée par le Chapitre 94 des lois de 1973, dont le siège social est à 850 Place d'Youville, Québec, un certificat d'enregistrement lui permettant d'effectuer des affaires de fidéicommis dans la province à compter du 1er janvier 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 56451-0 Albert Jessop.Notice is given that under the Trust Companies Act, a certificate of registration has been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"FIDUCIE PRET ET REVENU \u2014 SAVINGS AND INVESTMENT TRUST\", a company incorporated by Chapter 94, Statutes of Québec 1973, whose head office is at 850 D'Youville Square, Québec, authorizing the company to carry on trust business in the province as from January 1st, 1974.56451-0 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.March 16.1974.Vol.106.No.11 Demandes à la Législature Applications to Legislature Ville d'Anjou Avis est donné que la Ville d'Anjou s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, lors de sa prochaine session, pour obtenir l'adoption d'une loi spéciale en vue de refondre sa charte et obtenir certains pouvoirs nécessaires à la bonne administration de la Ville et, plus particulièrement, pour: 1° modifier les règlements d'emprunt de la Ville, pour répartir plus équitablement la chaige des contribuables; 2° modifier, pour la Ville, la Loi sur l'évaluation foncière; 3° régulariser les titres de la Ville sur certains biens faisant partie du domaine public: parcs, rues et autres; 4° déclarer applicables à la Ville les dispositions de l'article 429.paragraphe 8 de la Loi des cités et villes, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions; 5° établir un fonds résidentiel; 0\" emprunter au fonds de roulement pour défrayer certaines dépenses préliminaires, de nature capitale; et tous autres amendements qu'elle jugera nécessaires ou utiles pour la lionne administration des affaires de la Ville et de ses citoyens.Donné à Ville d'Anjou, le 21 février 1974.Les procureurs de la Ville d'A iijou.Me Armand Poupart, 5fi336-10-4-o Me François Wiliiklmy, avocats.La Communauté urbaine de Québec Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaine de Québec s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de la présente session, pour demander l'adoption d'une loi amendant sa loi constitutive pour en modifier les annexes, et entre autres dispositions, les définitions, la façon générale d'exercer ses pouvoirs, la procédure de mise en candidature à la charge de membre du comité exécutif, la durée des mandats et la procédure permettant de combler les vacances, la participation de la Communauté au paiement d'une partie de la pension du président du comité exécutif, les pouvoirs du comité exe-cutif, la composition du Conseil, la procédure de fixation de la date des assemblées du Conseil et la procédure de convocation, le calcul de la rémunération des membres du Conseil, la procédure de votât ion aux commissions du Conseil, les devoirs du secrétaire, les pouvoirs et la compétence île la Communauté, la procédure d'appel d'offres, les dispositions ayant trait à l'évaluation foncière, les titres de la Communauté sur ses terrains industriels, la procédure de disposition d'immeubles, certaines dispositions financières relatives aux emprunts et aux garanties, certaines dispositions concernant les modalités de perception de la répartition, certaines dispositions concernant le territoire périphérique, certaines Town of Anjou Notice is hereby given that the Town of Anjou will apply to the National Assembly of the Province of Québec, at its next session, for a special Act revising its charter and granting certain powers in view of the proper administration of its affairs and, more specifically: 1.To amend the loan by-laws of the City, in order to distribute more equitably the share of the taxpayers; 2.To amend, with respect to the municipality, the Real Estate Assessment Act; 3.To fix proper titles on certain immoveables forming part of the public property, such as parks, streets and others; 4.To declare that the provisions of Section 429, paragraph 8.of the Cities and Towns Act shall apply to the Town of Anjou, as of the coming into force of such provisions; 5.To establish a residential fund; 6.To borrow from the sinking fund, in order to pay preliminary expenses for capital works; and such other amendments, which it may deem useful and necessary for the proper administration of its affairs and those of the citizens.Town of Anjou.February 21, 1974.Me Armand Poupart, Me François Wii.hei.my.Advocates.56336-10-4-o The Attorneys for the Town of Anjou.Québec Urban Community Notice is hereby given that the Québec Urban Community will petition the National Assembly of the Province of Québec, at is present session, to modify it's schedules and the dispositions of its constitutive law, among others, to wit: the definitions, the general exercise of its powers, the procedure of nomination as a candidate for the Executive Committee, the term of office, the filling up procedure of vacancies, the Community's participation to the payment of a part of the Executive Committee Chairman's pension plan, the Executive Committee's powers, the composition of the Council, the procedure to determine the Council's meeting's date and convocations' procedure, the computation of the Council's members' remuneration, the voting procedure at the committees of the Council, the secretary's duties, the powers and competence of the Community, the calling for tenders' procedure, the real estate assessment's provisions, the titles of the Community on its industrial land, the procedure to dispose of its immoveables, some financial provisions relating to loans and guaranties, some provisions concerning collection of the apportionment of expenses, some provisions concerning the peripheral territory, some provisions concerning the preparation and the execution of the development plan, the GQWPB and GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' U 2239 dispositions concernant l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma d'aménagement, le financement du BAEQM et de la CTCUQ, la répartition du déficit de la CTCUQ, ainsi que certaines dispositions financières et autres concernant la régie interne de la CTCUQ, et pour toute autre disposition.Québec, ce 27 février 1974.Les avocats, 56269-9-4-0 Y van Dallaire et Jacques Fougues.QUCTC financing, the QUCTC deficit apportionment, and some financial provisions and other provisions pertaining to the QUCTC administration; and any other provisions.Québec, this February 27, 1974.Y van Dallaire and Jacques Forgues, 56269-9-4-0 Lawyers.EUGENE MARCOUX INC.MM.Eugène Marcoux et Michel Ladouceur et Dame Noëlla Morin-Marcoux donnent avis qu'ils déposent au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale du Québec un projet de loi ayant pour objet de révoquer la dissolution de la compagnie « EUGENE MARCOUX INC ».Sherbrooke, le 26 février 1974.Les procureurs des intéressés, 56362-10-4-o O'Bready, Rivard & Bessette.EUGENE MARCOUX INC.Notice is given that Eugène Marcoux, Michel Ladouceur and Noëlla Morin-Marcoux are filing with the Secretariat of the Commissions of the National Assembly of the Province of Québec a bill in order to obtain the revocation of the dissolution of \"EUGENE MARCOUX INC\".Sherbrooke, February 26, 1974.O'Bready, Rivard.& Bessette, 56362-10-4-o Attorneys for the Petitioners.Succession Sir Joseph David Rodolphe Forget Avis est par les présentes donné, que Jacques Nadeau, Roger Ouimet, Jacques Roy, Joseph Patrick Clément Gauthier et Guy Poliquin des ville et district de Montréal, agissant en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de la « Succession Joseph David Rodolphe Forget » s'adresseront à l'Assemblée Nationale du Québec pour l'adoption d'une loi aux fins d'avancer la date du partage et d'accélérer la remise des biens compris dans ladite succession aux légataires de feu Sir Joseph David Rodolphe Forget conformément aux dispositions testamentaires de ce dernier.Montréal, le 6 mars 1974.Les procureurs des requérants, McLean, Marler, Tees, Watson, 56496-11-4-0 Poitevin, Javet, & Roberge.Estate of Sir Joseph David Rodolphe Forget Notice is hereby given that Jacques Nadeau, Roger Ouimet, Jacques Roy, Joseph Patrick Clément Gauthier and Guy Poliquin of the City and District of Montreal, in their quality of testamentary executors of the \"Estate Sir Joseph David Rodolphe Forget\", shall apply to the Québec National Assembly, for the adoption of an Act, in order that it be proceeded earlier to the partition of the assets comprised in the said Estate, as well as to accelerate the distribution of such assets to the legatees of Sir Joseph David Rodolphe Forget, in conformity with his testamentary dispositions.Montreal, March 6th 1974.McLean, Marler, Tees, Watson, Poitevin, Javet & Roberge, 56496-11-4-0 Attorneys for Petitioners.Succession Tancrède Bienvenu Avis vous est, par les présentes, donné que M.Paul Poirier, notaire, domicilié à Ville Mont-Royal, M.Cecil Frank Carsley, M.B.E., exécutif, domicilié à Cité de Westmount, M.Arthur Simard, avocat et conseil en loi de la Reine, domicilié à Ste-Anne-de-Sorel, M.Emile Desourcy, administrateur, domicilié à Ville d'Outre-mont et M.Jacques St-Aubin, vice-président exécutif, domicilié à Ville St-Laurent, s'adresseront à la Législature provinciale, à sa prochaine session, aux fins d'obtenir ef'augmenter le montant payé en rentes viagères annuelles à certains héritiers et à certaines catégories d'héritiers en vertu des testament et codicilles de feu Tancrède Bienvenue ainsi que des honoraires annuels plus élevés aux exécuteurs testamentaires.Le 7 mars 1974.Les procureurs des requérants.Gagné, Trotier, Letarte, 56503-1 l-4-o Larue & Royer.Estate of Tancrède Bienvenu Notice is hereby given that Mr.Paul Poirier, notary, residing in Ville Mont-Royal, Mr.Cecil Frank Carsley, M.B.E., Executive, residing in Cité de Westmount, Mr.Arthur Simard, lawyer and Queen's Counsellor, residing in Sle-Annede-Sorel, Mr.Emile Desourcy, administrator, residing in Ville d'Outremont and Mr.Jacques St-Aubin executive vice-president, residing in Ville St-Laurent, shall apply to the Provincial Legislature, during its next Session, to have the authorization of increasing the annual life rent paid te> certain heirs anel certain categories of heirs under the will and codicils of Tancrède Bienvenu as well as higher annual fees to executors.March 7, 1974.Gagné, Trotier, Letaute, Larue & Royer, 56503-1 l-4-o Attorneys for Petitioners. 2240 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106.A'o.11 Communauté urbaine de Montréal Avis est par les présentes donné que la Communauté urbaine de Montréal, ayant son siège social dans la Ville de Montréal, s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa prochaine session, afin d'obtenir l'adoption d'une loi pour: 1.modifier la Loi de la Communauté urbaine de Montréal en vue de faciliter l'administration des affaires de cette dernière, de préciser certains de ses pouvoirs et d'étendre certains délais prévus dans cette loi pour l'adoption de différentes mesures; 2° autoriser la Communauté à exproprier aux fins d'un meilleur aménagement des abords et à effectuer, sans expropriation préalable, des travaux en sous-sol lorsque ces travaux s'effectuent au-delà d une profondeur déterminée; 3° dispenser la Communauté de faire approuver par le conseil les contrats accordés au plus bas soumissionnaire, lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire; 4° prescrire les pénalités imposables en rapport avec les règlements concernant les aliments et prévoir des sanctions aux règlements de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 5° modifier les délais de dépôt et d'adoption du budget et préciser les dispositions relatives aux emprunts .li- lu Communauté et il.- la Commission de t ran-.port de la Communauté urbaine de Montréal: 6° prévoir des dispositions relatives à la prescription des recours contre la Communauté et préciser quels sont les documents publics de la Communauté; 7° modifier la Loi du Boulevard métropolitain aux fins de prévoir que la Communauté n'exproprie plus et n'a plus à repartir pour les fins des voies latérales et prévoir l'arbitrage des différends concernant les repartitions du coût de ces voies latérales; et à diverses autres fins.Montréal, le 26ièmc jour de février 1974./.es procureurs.Beaupré, Trudeau, Sylvestre 56343-10-4-o & Taillefer.Avis divers C.J.AUTO LTEE Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Ix>i des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 6 décembre 1973, de la compagnie « J.G.AUTO LTEE», paru dans la Gazelle officielle du 2 mars 1974, numéro 9, à la page 1652, en y remplaçant dans ledit nom « J.G.» par « G.J.», de manière que le nom de lise ainsi: « G.J.AUTO LTEE».Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.56436-0 735387 Montreal Urban Community Notice is hereby given that Montreal Urban Community, having its corporate seat in the City of Montreal, will apply to the National Assembly of Québec at its next session to obtain the adoption of an Act so as to: 1.amend the Montreal Urban Community Act to facilitate the administration of said Community, clarify certain of its powers and extend certain delays prescribed in such Act for the adoption of various measures; 2.authorize the Community to expropriate for a better lay-out of the approaches, and to effect underground works, without prior expropriation, provided such works are made beyond a prescribed depth; 3.dispense the Community of the approval of the Council for contracts awarded to the lowest bidder, whenever there is only one bidder; 4.prescribe penalties with respect to by-laws concerning food products and provide for sanctions to by-laws of the Montreal Urban Community Transit Commission; 5.modify the delays for the filing and adoption of the budget and clarify provisions related to loans of the Community and the Montreal Urban Community Transit Commission; 6.include provisions concerning the prescription of claims against the Community and determine the public documents of the Community; 7.modify the Metropolitan Boulevard Act to provide that the Community does no longer expropriate for purposes of the lateral roads and apportion the expenses therefor and provide for the arbitration of litigation concerning the apportionments of the cost of such lateral roads; and for various other purposes.Montreal, this 26th day of February 1974.Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 56343-10-4-o Attorneys.Miscellaneous Notices G.J.AUTO LTEE Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent, dated December 6, 1973, of \"J.G.AUTO LTEE\", published in the Québec Official Gazette.dated March 2, 1974, issue number 9, on page 1652, by replacing in said name \"J.G.\" by \"G.J.\", so that the name may read as follows: \"G.J.AUTO LTEE\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56436 735387 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974.106' année, n' U 2241 CHAUFFAGE ELECTROCHIMIQUE PEPIN INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 6 février 1974.de la compagnie « CHAUFFAGE ELECTRONIQUE PEPIN INC.», paru dans la Gazelle officielle du 2 mars 1974, numéro 9.à la page 1650, en y remplaçant dans ledit nom le mot « ELECTRONIQUE » par le mot «ELECTROCHIMIQUE », de manière que le nom se lise ainsi: « CHAUFFAGE ELECTROCHIMIQUE PEPIN INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56436-0 740522 CHAUFFAGE ELECTROCHIMIQUE PEPIN INC.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent, dated February 6, 1974, of \"CHAUFFAGE ELECTRONIQUE PÉPIN INC.\", published in the Québec Official Gazelle dated March 2, 1974, issue number 9, on page 1650, by replacing in said name the word \"ELECTRONIQUE\" by the word \"ELECTROCHIMIQUE\", so that the name may read as follows: \"CHAUFFAGE ELECTROCHIMIQUE PEPIN INC.\".Pierre Desjardins.Director of Companies Service.56436 740522 CLUB MOTO-NEIGE CHERTSEY Le ministre des institutions financières compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes en date du 28c jour de novembre 1973 constituant en corporation sans capital-actions les membres actuels de « CLUB MOTO-NEIGE CHERTSEY » déjà constituée en corporation le ou vers le 12 octobre 1972 en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus 1964 chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $25,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Chert-sey, district judiciaire de Joliette.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56436-0 735289 CLUB MOTO-NEIGE CHERTSEY The Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives gives notice that under Part III of the Companies Act he has granted letters patent dated November 28 1973 constituting in corporation without share capital the present members of \"CLUB MOTO-NEIGE CHERTSEY\" previously incorporated on or around October 12 1972 under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited is $25,000.The head office of the new corporation is in Chertsey, Judicial District of Joliette.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56436 735289 LA PROVINCE CANADIENNE DES PERES DE SAINTE-CROIX Le ministre des institutions financières compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des corporations religieuses, chapitre 75 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 30e jour de janvier 1974, constituant en corporation régie par la Loi des corporations religieuses, Maurice Dubé, Robert Choquette, tous deux de 3160, chemin Daulac, Marcel Taillefer.3800, chemin Reine-Marie, G aston Joly, 2600, avenue Desjardin.s, tous quatre de Montréal, et Bernard Lacroix, 2180, rue Kensington, Saint-Hubert, tous prêtres.I-e montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $5,000,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.56436-o 740459 LA PROVINCE CANADIENNE DES PERES DE SAINTE-CROIX The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, under the Religious Corporations Act, Chapter 75 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent dated January 30 1974, constituting into a corporation governed by the Religious Corporations Act, Maurice Dubé, Robert Choquette, both residing at 3160 Daulac Road, Marcel Taillefer, 3800 Queen Mary Road, Gaston Joly, 2600 Desjardins Avenue, all four of Montreal and Bernard Lacroix, 2180 Kensington Street, St.Hubert, all priests.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited is $5.000,000.The head office of the corporation is in Montreal, Judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56436 740459 2242 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 CLUB DE MOTOS QU-BEC DE THETFORD MINES INC.Avis est donné qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes, en date du 12 février 1974, de la compagnie « CLUB DE MOTOS QUEBEC DE THETFORD MINES INC», paru dans la Gazelle officielle du 2 mars 1974, numéro 9, à la page 1657, en y remplaçant dans ledit nom le mot « QUEBEC » par le mot « QU-BEC », de manière que le nom se lise ainsi: « CLUB DE MOTOS QU-BEC DE THETFORD MINES INC.».Le directeur du service des compagnies, Pifkhk Desjardins.56436-0 740528 CLUB DE MOTOS QU-BEC DE THETFORD MINES INC.Notice is given that, under Part HI of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent, dated February 12, 1974, of \"CLUB DE MOTOS QUEBEC DE THETFORD MINES INC\", published in the Québec Official Gazette, dated March 2, 1974, issue number 9, on page 1657, by replacing in said name, the word \"QUEBEC\" by the word \"QU-BEC\", so that the name may read as follows: \"CLUB DE MOTOS QU-BEC DE THETFORD MINES INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.56436 740528 Succession Normand Thuot Avis public est par les présentes donné que Monsieur Léon Thuot, en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs Ginette et Serge Thuot, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Normand Thuot, en son vivant mécanicien, demeurant au numéro 552 rue Labelle, à St-Jérôme, province de Québec, par acte passé le 27 octobre 1973, devant le notaire Jean-Paul Hogue, 655-92e Rue, Ville de St-Antoine, P.Q.et enregistré le 17 décembre 1973 au bureau de la division de Terrebonne sous le numéro 432565.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant le notaire Réal Payette et peut être consulté à ses bureaux, à l'adresse suivante: 655 - 9e Rue, Ville de St-Antoine, comté de Prévost, P.Q.Après deux mois du présent avis, le bénéficiaire paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, selon la loi.Donné à Ville de St-Antoine, ce quinze février mil neuf cent soixante-quatorze.Le tuteur.56454-0 Léon Thuot.Estate of Normand Thuot Public notice is hereby given that Mr.Léon Thuot, in his capacity as tutor to his minor children, Ginette and Serge Thuot, has accepted under benefit of inventory the estate of Normand Thuot, in his lifetime a mechanic, residing at 552 Labelle Street in St.Jérôme, Province of Québec, under the terms of a deed executed on October 27, 1973, before Jean-Paul Hogue, notary, 655-92nd Street, in the Town of St.Antoine, P.Q., and registered on December 17, 1973 at the Registry Office of Terrebonne, under number 432565.An inventory of the property of the deceased has been drawn up by Real Payette, notary, and may be examined at his office, at the following address: 655 - 9th Street, Town of St.Antoine, County of Prévost, After two months following publication of the present notice, the beneficiary will settle with the creditors as they present themselves, according to law.Given in the Town of St.Antoine, this fifteenth day of February one thousand nine hundred seventy-four.Léon Thuot, 56454 Tutor.Corporation municipale du village de I fRS.ALICE RACICOT GÉLINAS, No.26.807X industrialist, domiciled in St.Pe- v tersburg Beach, Florida, United States of America, and also in Cabano, District of Kamouraska, wife separate as to property of Richard Gélinas, same 2266 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 endroits, demanderesse, vs ARSÈNE LEVESQUE, de Ste-Rita, comté de Rivière-du-Loup, dans le district de Kamouraska, défendeur.« Le lot numéro 19 canton Raudot, cinquième (5e) rang du cadastre officiel de la paroisse Sainte-Rita dans le district de Kamouraska.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement division de Témiscouata, situé à 65A, rue Iberville, Rivière-du-Loup, le VINGT-TROISIÈME jour d'AVRIL 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif, 56510-o Maurice Morin.MONTRÉAL Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( JN AME GIUSEPPINA GIZZI.No 05-012441-72X -L-' demanderesse, vs MUZZIO v DI VICO ET AL, défendeurs et MLLE INES DE VICO, demanderesse en reprise d'instance.Conformément au jugement de l'honorable Juge Paul Trépanier, de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, en date du 26e jour de novembre 1973, ordonnant la licitation de l'immeuble ci-après décrit.« Un emplacement ayant front sur la rue Rordeaux, en la Cité de Montréal, composé du lot No cent trois de la subdivision du lot No quatre cent soixante et dix-neuf et du lot No deux cent seize de la subdivision du lot No quatre cent quatre-vingt-un (479-103 et 481-216) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse du Sault-au-RécolIet, ces deux lots mesurant ensemble vingt-cinq pieds de largeur par cent pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, avec la maison portant le No 7664, de la rue Bordeaux avec tous les droits dans la ruelle conduisant audit emplacement.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le DIX-SEPTIÈME jour d'AVRIL 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 7 mars 1974.56512-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( JEAN GAUTHIER & JEAN Cour Supérieure J J PAUL THIBAULT, sociétaires No 15-982.) de GAUTHIER & THIBAULT { ENR., faisant affaires au 125 boul.Benoit XV, suite 704, Québec, contre MYROY CONSTRUCTION INC., ayant une place d'affaires à 135, 47e rue Est, Charlesbourg, P.Q.addresses, plaintiff, vs ARSÈNE LEVESQUE, of Ste.Rita, County of Rivière-du-Loup, District of Kamouraska, defendant.\"Lot number 19, Township of Raudot, in the Fifth (5th) Range of the official cadastre for the Parish of Ste.Rita in the District of Kamouraska.\" To be sold at the Témiscouata Division Registry Office, 65A Iberville Street, Rivière-du-Loup, on the TWENTY-THIRD day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Maurice Morin, 56510-o Skeriff.MONTREAL Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal I \\yfRS.GIUSEPPINA GIZZI, No.05-012441-72X L\\L plaintiff, vs MUZZIO FLAMAND LTEE, a corpo-No.16-484.\\ ration legally incorporated having ' its head office and its main place of business in St.Agapit, County of Lotbinière, District of Québec, vs MYROY CONSTRUCTION INC., a corporation legally incorporated carrying on business at 135-47th Street East, in Charlesbourg, District of Québec.(a) An immoveable known and described as being lot 575-42 on the official cadastre for the parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2410 Costebelle Street in Québec, District of Québec; (h) An immoveable known and described as being lot 575-43 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected 2268 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2420, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; e) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-44 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2430, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; d) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-45 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeunc-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2440, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; e) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-46 du cadastre officiel de la paroisse de St-Am-broise-de-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2450, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; /) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-47 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2460, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; g) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-48 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-.Ieune-I.orette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2470, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; h) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-49 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-dc-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2480, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; i) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-50 du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2490, de la rue Costebelle, à Québec, district de Québec; j) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-51 du cadastre officiel delà paroisse de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2500, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; k) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-52 du cadastré officiel de la paroisse de St-Ambroise-de-la-.Jeune-Lorette avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2510, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec; /) Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 575-53 du cadsatre officiel delà paroisse de St-Ambroise-dc-la-.!eune-Lorette avec bâtisses dessus construites.thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2420 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (c) An immoveable known and described as being lot 575-44 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2430 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (d) An immoveable known and described as being lot 575-45 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2440 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (e) An immoveable known and described as being lot 575-46 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2450 Costebelle street, in Québec, District of Québec; (/) An immoveable known and described as being lot 575-47 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2460 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (g) An immoveable known and described as being lot 575-48 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2470 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (h) An immoveable known and described as being lot 575-49 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2480 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (t) An immoveable known and described as being lot 575-50 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2490 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (j) An immoveable known and described as being lot 575-51 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2500 Costebelle Street, in Québec, District of Québec; (k) An immoveable known and described as being lot 575-52 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2510 Costebelle Street in Québec, District of Québec; (0 An immoveable known and described as being lot 575-53 on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, with buildings erected there- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1971,, 106' année, n\" 11 2269 circonstances et dépendances, et également connu sous le numéro civique projeté 2520, de la rue Costebelle à Québec, district de Québec.Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le VINGT-DEUXIÈME jour du mois d'AVRIL 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 11 mars 1974 .56523-o SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de St-François Bedford, l T EON DESROCHERS, arpenteur-géo-No 3079A Aj mètre y faisant affaires au 116 ave.I du Parc, à Granbv.district de Bedford, demandeur, M BARRY INTERNATIONAL LTD., compagnie légalement constituée, ayant sa place d'affaires au 600, boulevard Dorchester ouest, 3e étage, Montréal 101.district de Montréal, défenderesse.« Les lots 8d, 96 et 9c du 3e rang du canton de Barnston : 1.À distraire une partie du lot 9c vendu au ministère de la Voirie par acte passé devant Me Antoine Guérin, et enregistré sous le No 33186 du bureau d'enregistrement de Coaticook.2.A distraire partie du lot 9c propriété de M.Marc Deslandes, mesurant 300 pieds en front le long de la route, 105 pieds dans sa ligne nord, 328 pieds dans sa ligne sud.3.À distraire partie du lot 96 propriété de Michael Savage et Diane Savage borné à l'est par le chemin public, à l'ouest pat le lot 8d, au sud par le résidu du lot 96 et au nord par le lot 9a.» Pour être vendus en bloc au bureau d'enregistrement, à Coaticook, P.Q., MARDI, le VINGT-TROISIÈME jour d'AVRIL 1974, à DIX heures de la matinée.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Palais de Justice, Jean Guy Bisson.Sherbrooke, P.Q., ce 8 mars 1974.56507-o TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Terrebonne ( Ô ASTON BERTHIAUME, machinis-No 66,764.\\ te, résidant et domicilié au numéro ' 1375, rue Daigneault, ville LaSalle, district de Montréal, défendeur, vs VIRGIL NOTO, sa dernière adresse connue étant Laurel, comté d'Argenteuil, district de Terrebonne, province de Québec et DAME CLAUDETTE BERTHIAUME, divorcée de FRANCTESCO OREFICE, sa dernière adresse connue étant Laurel, comté d'Argenteuil, district de Terre-bonne, province de Québec, défendeurs.on, appurtenances and dependencies, and also known under the proposed civic number 2520, Costebelle Street, in Québec, District of Québec.To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the TWENTY-SECOND day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, March 11, 1974.56523 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Superior Court \u2014 District of St.François Bedford, l T ÉON DESROCHERS, land-surveyor No.3079a carrying on business here at 116 Park V Ave.in Granby, District of Bedford, plaintiff, vs BARRY INTERNATIONAL LTD., a company legally incorporated, having its place of business at 600 Dorchester Boulevard West, 3rd Floor, Montreal 101, District of Montreal, defendant.\"Lots 8a\", 96 and 9c in Range 3 in the Township of Barnston: 1.To withdraw a part of lot 9c sold to the Roads Department by a deed executed before Me Antoine Guérin and registered under No.33186 in the Registry Office for Coaticook.2.To withdraw a part of lot 9c, property of Mr.Marc Deslandes, measuring 300 feet in front along the road, 105 feet on its north line and 328 on its south line.3.To withdraw a part of lot 96, property of Michael Savage and Diane Savage, bounded on the east by the public road, on the west by lot 8d, on the south by the remainder of lot 96 and on the north by lot 9a.\" To be sold \"in block\" at the Registry Office in Coaticook, P.Q., on TUESDAY, the TWENTY-THIRD day of APRIL, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Jean Guy Bisson, Court House, Assistant Sheriff.Sherbrooke, P.Q., March 8.1974.56507 TERREBONNE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne ( p ASTON BERTHIAUME, machinist.No.66,764a residing and domiciled at 1375 \\ Daigneault Street, in Ville LaSalle, District of Montreal, plaintiff, vs VIRGIL NOTO, his last known address being Laurel, County of Argenteuil, District of Terrebonne, Province of Québec, and DAME CLAUDETTE BERTHIAUME, divorced wife of FRANC1ESCO OREFICE, her last known address being Laurel, County of Argenteuil, District of Terrebonne, Province of Québec. 2270 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 L'immeuble ci-après désigné, savoir: « Un certain morceau de terre connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Wentworth comme faisant partie du lot numéro vingt-deux lettre « B » dans le Huitième Rang (Ptie 22B-R.8), mesurant à partir du coin nord-est de la propriété de Georges Pellerin, ou représentants, et parcourant vers l'ouest une distance de cent cinquante pieds (150').de là tournant à angle droit et parcourant vers le nord une distance de cent pieds ( 100'), de là tournant à angle droit et parcourant vers l'est une distance de deux cent quarante-sept pieds (247'), de là tournant à angle droit et suivant la route Coops pour une distance de cent onze pieds (111') au point de départ; Borné à l'est partie par la route Coops et partie par la propriété de Dame Hazel Morrow Ferguson, ou représentants, au sud par la propriété de Georges Pellerin, à l'ouest par la propriété de Dame Hazel Morrow Ferguson, ou représentants, et au nord par la propriété de R.Marcotte, ou représentants, mesure anglaise et plus ou moins.Avec toutes les bâtisses y érigées.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil, situé à 430, rue Grâce, Laehute, MERCREDI le DIX-SEPTIÈME jour d'AVRIL 1974 à QUINZE heures.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Muir.Saint-Jérôme, le 7 mars 1974.56532-0 The immoveable hereinafter described, to wit: \"A certain parcel of land known and described on the official plan and in the book of reference for the Township of Wentworth as forming part of lot number twenty-two letter \"B\" in Range Eight (Pt.22B-R.8), measuring, from the northeast corner of the property of Georges Pellerin.or representatives, and proceeding towards the west, a distance of one hundred fifty feet (150'), thence turning at right angles and proceeding towards the north, a distance of one hundred feet (100'), thence turning at right angles and proceeding towards the east, a distance of two hundred forty-seven feet (247'), thence turning at right angles and proceeding along Coops Road, a distance of one hundred eleven feet (ill'), up to the starting point; Bounded on the east partly by Coops Road and partly by the property of Mrs.Hazel Morrow Ferguson, or representatives, on the south by the property of Georges Pellerin, on the west by the property belonging to Mrs.Hazel Morrow Ferguson, or representatives, English measure and more or less.With all the buildings erected thereon.\" To be sold at the Registry Office of the County of Argenteuil, located at 430 Grâce Street, Lachute, on WEDNESDAY, the SEVENTEENTH day of APRIL, 1974, at THREE o'clock in the afternoon.Jean-Louis Muir, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, March 7, 1974.56532 Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Terrebonne / VW'ESTMOUNT LIFE INSURANCE No 66,409.< VV CO., corps politique légalement * constitué et ayant sa principale place d'affaires en la ville de Westmount, province de Québec, demanderesse, vs JOSEPH F.LOBOSCO, résidant au 110 Longmore Drive, en la ville de Pointe-Claire, province de Québec, défendeur, et LE REGISTRA-TEUR du bureau d'enregistrement d'Argenteuil, mis en cause.L'immeuble ci-après désigné, savoir: « Un emplacement situé sur la rive du lac des Seize îles, mesurant deux cents pieds de largeur en front et à l'arrière sur une profondeur de deux cents pieds dans sa ligne latérale nord-ouest, et deux cents pieds dans sa ligne latérale sud-est, mesure anglaise et plus ou moins, et composé de parties des lots originaires numéros trente-cinq et trente-six (Pties 35 et 36), dans le premier rang (Rg.1) du canton de Montcalm, aux plan et livre de renvoi officiels dudit canton de Montcalm, et étant cette partie desdits lots originaires numéros 35 et 36, comprise dans les bornes de fer « A, B, C et D », le point « D » étant marqué par une borne de fer située à environ quatre cents pieds au nord d'une borne de fer indiquant la limite nord de la propriété de Mme Boright, ou représentants; bornée en front par le lac des Seize Iles, à l'arrière et des autres côtés par d'autres parties desdits lots numéros 35 et 36, le tout tel qu'il est indiqué sur un plan annexé à l'acte de vente par les exécuteurs Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne ( \\\\ /\"ESTMOUNT LIFE INSURANCE No.66,409.< VV CO., a body politic legally in-\\ corporated and having its principal place of business in the City of Westmount, Province of Québec, plaintiff, versus JOSEPH F.LOBOSCO, residing at 110 Longmore Drive, in the City of Pointe-Claire, Province of Québec, defendant, and THE REGISTRAR for the Argenteuil Registry Office, mis en cause.The immoveable hereinafter described, to wit: \"An emplacement situate on the shore of Sixteen Island Lake, having a width in front and in rear of two hundred feet by a depth on the northwest side line of two hundred feet and on the southeast side line of two hundred feet, English measure and more or less and being composed of parts of original lots numbers thirty-five and thirty-six (Pts.35 and 36), in the First Range (R.1) of the Township of Montcalm, on the official plan and book of reference of the said Township of Montcalm, and being that part of said original lots numbers 35 and 36, enclosed within iron stakes, \"A, B, C and D, the point \"D\" being an iron stake approximately four hundred feet north of an iron pin forming the north boundary of the property of Mrs.Boright, or representatives; bounded in front by Sixteen Island Lake, in rear and on the other sides by other parts of said lots numbers 35 and 36, the whole as shown on a plan annexed to the deed of sale from the Execu- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 mars 1974, 106' année, n' U 2271 de la succession de feu Tracy Ludington à Mademoiselle Evelyn Kate Elderkin, passé devant le notaire R.H.Bridgman, le dixième jour de janvier mil neuf cent quarante-deux, enregistré au bureau d'enregistrement de la division du comté d'Argenteuil, sous le numéro 54438.Tel que ledit immeuble existe présentement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.» « Une lisière de terrain mesurant vingt pieds de largeur sur uDe profondeur de deux cents pieds, mesure anglaise et plus ou moins, comprenant une partie du lot numéro trente-cinq (Ptie 35), dans le premier rang dudit canton de Montcalm, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Montcalm, ladite lisière de terrain étant la demie nord-ouest dudit lot numéro trente-cinq t}/i N.O.35), et bornée au sud-est par la propriété ci-dessus décrite, au sud-ouest par le lac des Seize Iles et des deux autres côtés par le résidu dudit lot numéro 35.Tel que ledit immeuble existe présentement avec tous ses droits, membres et circonstances sans exception ni réserve d'aucune sorte de la part du vendeur.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté d'Argenteuil, situé à 430, rue Grâce, Lachute, P.Q., MERCREDI, le DIX-SEPTIÈME jourd'AVRIL 1974 à quatorze heures.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif.Gabrielle Fournelle.Saint-Jérôme, le 6 mars 1974.56533 tors of the Estate of the late Tracy Ludington to Miss Evelyn Kate Elderkin, executed before R.H Bridgman, Notary, on the tenth day of January nineteen hundred and forty-two, registered in the Registry Office for the Registration Division of the County of Argenteuil under number 54438.As the said immoveable property now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.\" \"A strip of land measuring twenty feet in width by two hundred feet in depth, English measure and more or less, composed of part of lot number thirty-five (Pt.35), in the First Range of the said Township of Montcalm, on the official plan and book of reference of the Township of Montcalm, the said piece of land being the northwest half of said lot number thirty-five (N.W.J/2 35), and being bounded to the southeast by the property hereinafter described to the southwest by Sixteen Island Lake and on the other two sides by the residue of said lot number 35.As the said immoveable property now subsists with all its rights, members and appurtenances without exception or reserve of any kind on the part of the vendor.\" To be sold at the County of Argenteuil Registry Office, at 430 Grâce Street.Lachute.Québec, on WEDNESDAY, the SEVENTEENTH day of APRIL, 1974, at TWO o'clock in the afternoon.Gabrielle Fournelle, Sheriff's Office.Assistant Sheriff.St.Jérôme, March 6, 1974.56533-0 Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Terrebonne I T5ANQUE DE COMMERCE CANA-No 66,932.< -D DIENNE IMPERIALE, corpora-t tion dûment constituée, ayant son siège social et sa principale place d'affaires à 1155 ouest, boulevard Dorchester, cité et district de Montréal, demanderesse, vs GEORGES FILION, particulier, résidant et domicilié au 17, rue St-Jacques est, Ste-Thé-rèse-de-Blainville, district de Terrebonne, défendeur.L'immeuble ci-après désigné, savoir: « Un emplacement situé sur la rue Turgeon en la ville de Ste-Thérèse, connu et désigné comme étant le lot numéro deux de la subdivision officielle du lot numéro deux cent soixante-cinq (265-2) aux plan et liv^e de renvoi officiels du village de Ste-Thérèse-de-Blain-ville, avec une maison et d'autres bâtisses y construites et plus patriculièrement l'immeuble portant numéro civique 71, rue Turgeon, Ste-Thérèse.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Terrebonne, situé chambre 106, Palais de Justice, 400 rue Laviolette, Saint-Jérôme, JEUDI, le DIX-HUITIÈME jour d'AVRIL 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Muir.St-Jérôme, le 7 mars 1974.56513-0 Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne I /CANADIAN IMPERIAL BANK OF No.66,932.< COMMERCE, a corporation duly t incorporated, having its head office and its principal place of business at 1155 Dorchester Boulevard West, City and District of Montreal, plaintiff, M GEORGE FILION, private citizen, residing and domiciled at 17 St.Jacques Street East, Ste.Thérèse-de-Blainville, District of Terrebonne, defendant.The immoveable hereinafter described, to wit: \"An emplacement located on Turgeon Street in the City of Ste.Thérèse, known and described as being lot number two of the official subdivision of lot number two hundred sixty five (265-2) on the official plan and in the book of reference for the Village of Ste.Thérèse-de-Blainville, with a house and other buildings erected thereon and particularly the immoveable bearing civic number 71 Turgeon Street, Ste.Thérèse.\" To be sold at the Registry Office for the Terrebonne Division, located in Room 106, Court House, 400 Laviolette Street, St.Jérôme, on THURSDAY, the EIGHTEENTH day of APRIL 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Jean-Louis Muir, Sheriff's Office, Sheriff.St.Jérôme, March 7, 1974.56513 2272 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, March 16, 1974, Vol.106, No.11 Erratum District dc Terrebonne, C.S.No 64,688.SOCIÉTÉ CENTRALE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT vs LES HÉRITIERS LÉGAUX DE
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.