Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 mai 1974, Partie 1 samedi 4 (no 18)
[" GAZETTE QUEBEC OFFICIELLE OFFICIAL -DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES PART 1 JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' aimée, n° 18 3299 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient desavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Quebec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 3300 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n° 18 3301 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4.5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ADJUSTMENT BUREAU OF MONTREAL INC.L'AIDE AUX ETUDIANTS DU COLLEGE DE LA SALLE DE THETTFORD MINES INC AIR MONT-LAURIER INC.ALLIANCE METROPOLITAINE DE LA RECREATION.ALUMINUM CONTAINERS LTD.AMEL PAPER BOX CO.LTD.AMEUBLEMENT CITE JARDIN.ASSOCIATION DE COMMERCES, INDUSTRIES ET AFFAIRES DE SAINT-TITE (A.C.I.A.) L'ASSOCIATION DES DIPLOMES DU COURS DU SOIR EN SCIENCES COMPTABLES DE LA FACULTE DE COMMERCE DE L'UNIVERSITE LAVAL INC.L'ASSOCIATION DES EDUCATEURS DU CENTRE ADMINISTRATIF (CECM) L'ASSOCIATION DES EPICIERS-RESTAURATEURS DU COIN DU COMTE JONQUIERE-KENOGAMI INC.L'ASSOCIATION DES PETITS COMMERÇANTS DE LA VILLE DE HULL ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU CHEMIN DU BAUME DE TERRES ROMPUES ASSOCIATION SPORTIVE D'IBERVILLE INC.L'ASSOCIATION DES VETERANS DE TENNIS DE LA MAURICIE INC.ATLAS DETECTIVE BUREAU INCORPORATED.AUTO PARC RIVERSIDE INC.BARBIZON MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).BAYSHORE INDUSTRIES OF CANADA LTD.J.C.BEDARD INC.Montréal.1952 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1954 à/to 1966 incl., 1968 à/to 1973 incl.Mont-Laurier.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1954, 1957, 1959 à/to 1973 incl.St-Tite.1971 à/to 1973 incl.Québec.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Jonquière.1964 à/to 1973 incl.Hull.1954 à/to 1973 incl.Arvida.1969 à/to 1973 incl.Iberville.1953, 1960, 1962 à/to 1973 incl.Shawinigan.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1956, 1959 à/to 1973 incl.Saint-Lambert.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Québec.1956, 1957, 1958, 1960 à/to 1973 incl. 3302 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 Nora de la compagnie Name of the company Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1957, 1959 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1955 incl.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1958, 1961.1963 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts .1956.1957, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1958 à/to 1973 incl.Amos.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Asbestos.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Shawinigan Falls.1958 à/to 1973 incl.Grondines.1963 à/to 1973 incl.Warwick.1954.1957 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.St-Ferdinand d'Halifax .1955 à/to 1973 incl.Drummondville.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Ste-Anne-de-la-Pocatière 1953 à/to 1973 incl.Montréal.1953 à/to 1955 incl., 1958, 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Québec.1969 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1966 à/to 1973 incl.Beloeil.1956 à/to 1973 incl.Granby.1956 à/to 1973 incl.Malartic.1964 à/to 1973 incl.Ville St-Laurent.1955 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1962, 1971 à/to 1973 incl.St^Félicien.1966, 1969 à/to 1973 incl.BELCRAFT PANTS CO.LTD.LA BELLE HANDBAGS CO.BENEFIT REALTY CORPORATION.J.R.BENOIT TAILLEUR & VALET SERVICE INCORPOREE LA BIBLIOTHEQUE DES JEUNES DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS INC.BIJOUTERIE ROBERT JEWELLERY INC.ULRIC BINETTE & FILS, INC.PHILIPPE BOULET INC.BRILL RECORDS & MUSIC INC.BROMO CEDIN LTEE.C.F.T.CONSTRUCTION CO.LTD.LES CADETS-CHEVALIERS NOTRE-DAME D'ASBESTOS INC.CALUMET INVESTMENTS LIMITED.CENTRALE SPORTIVE ST-GEORGES INC.CENTRE OUVRIER DE LA MAURICIE.J.CHALIFOUR & FILS INC.LA CHAMBRE DE COMMERCE DES JEUNES DE WARWICK INC.LA CHAMBRE DE COMMERCE SENIOR DE ST-FERDINAND LES CHANTIERS DE DRUMMONDVILLE INC.CHARRY GOWNS INC.CINEMA POCATIERE INC.5-10-15 AUTOMOBILE LIMITEE.CLAIRMONT TRADING INC.CLIX FASTENER CORPORATION.LE CLUB HIPPIQUE DE QUEBEC LTEE.CLUB DES PINS DE RIVIERE-DU LOUP-INC.CLUB RICHELIEU BELOEIL.CLUB RICHELIEU GRANBY.CLUB DE SKI DE MALARTIC INCORPOREE.CLUB DES ZOULOUS DE VILLE ST-LAURENT.COLLEGE COMMERCIAL DESMARAIS DE VICTORIA VILLE INC.COMITE DES OEUVRES DE LOISIRS DE ST-FELICIEN INC. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1971, 106' année, n° 18 3303 Nom de la compagnie Name of the company LA COMPAGNIE FAUCHARD LTEE.LE COMPTOIR INDUSTRIEL INCORPOREE.CONCORD PLAZA MERCHANTS ASSOCIATION.CONFECTION MODERNE LTEE.CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHIROPRATIQUE POUR LA PROVINCE DE QUEBEC INC.CONTINENTAL CAFE INCORPORATED.CONTINENTAL WAREHOUSE & TRANSFER LTD.CORPORATION DES CHEMINS D'HIVER DE STE-THECLE CORPORATION MINIERE EASTMAN INC.LA CORPORATION REL.EX LTEE.PHIL COTE LTD.FERDINAND COUTURE LTEE.PAUL DE VILLERS & FILS INC.DELMONT INVESTMENT CORPORATION.DeSALES URANIUM MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) DESMARAIS AUTOMOBILE LTEE.L.DESRUISSEAUX & L.P.RHEAULT LIMITEE.LES DEVELOPPEMENTS DU MOULIN ET DE LA RIVIERE JAUNE INC.DI PIETRO & FRERES INC.(ST-CATHERINE EST).DOMINION TILE A TERRAZZO CO.LTD.ARTHUR DOUCET LIMITEE .DRUMMOND AUTOMOBILE INC.DUFOUR & DUFOUR LTEE.E.O.AUTO RENTALS LTD.E.& M.SURGICAL SUPPLIES LTD.EASTERN CEREAL FOOD PRODUCTS CO.LTD.L'ECOLE D'AGRICULTURE DE MONT-LAURIER.ECOLE MAIMONIDE.EDITIONS DE LA NOUVELLE-FRANCE INC.EDLON CO.LTD.ELECTRO-REAGENTS (QUEBEC) LIMITED.LES ENTREPRISES EDGAR NAULT LTEE.LES ENTREPRISES LE PRINCE INC.LA FANFARE VAL-D'OR-BOURLAMAQUE INCORPOREE.Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Kénogami.1964 à/to 1966 incl.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1957 à/to 1959 incl.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Magog.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Ste-Thècle 1955 à/to 1973 incl.(La violette) Amos.1969 à/to 1973 incl.Grand'Mère.1963 à/to 1973 incl.Roberval.1954 à to 1973 incl.Thetford Mines.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1955 à/to 1973 inol.Montreal.1961 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Drummondville.1961 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1956 à/to 1973 incl.Québec.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1952, 1954 à/to 1973 incl.NaUdville.1956 à/to 1973 incl.Drummondville.1954 à/to 1973 incl.Sacré-Coeur.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 inol.St-Mathias.1961 à/to 1973 inol.Mont-Laurier.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Melocheville.1961 à /to 1973 incl.Thetford Mines.1969 à/to 1973 incl.Iberville.1967 à/to 1973 incl.Val d'Or.1954 à/to 1973 incl. 3304 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 1, 1971, Vol.106, No.18 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed FECTEAU & NANTEL PLASTIC NEON INC.FEDERAL CONVERTERS COMPANY.FERNHILL TRADING CORPORATION.FINANCIAL ADJUSTERS LTD.FLEURISTE MADELON LTEE.FOAMOLATE PRODUCTS LTD.FOUR SIXTY-FOUR ST-MATHIAS INC.LES FRAIS FUNERAIRES DUPUIS LIMITEE FURY SPEED WAY COMPANY LTD.CAOUETTE & FILS INC.GARAGE FERN AND TREMBLAY LIMITEE.GARAGE PORT-CARTIER LTEE.GASPE GAZ UTILITES INCORPOREE.JIM GAUTHIER & FILS LIMITEE.GOURMET PUBLISHING CO.LTD.GRANBY CONSTRUCTION LTEE.GRANOLUX QUEBEC INC.GREGORY & COMPANY INC.GUARDLVN FURNITURE SALES & SERVICES INC.LES HABITATIONS LAPRAIRIE INC.L'HARMONIE DE DISRAELI.HOLPAR HOLDINGS p PETROLES LIMITEE 18-000 357-740.< AJ partie demanderesse, vs I ADMIRAL CONSTRUCTION CO.LTD partie défenderesse, « Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision trois cent quatre-vingt-dix-nenf (399) de lot originaire soixante-douze (72) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, situé sur la rue Aldred Crescent, en la ville d'Hampstead, district de Montréal.Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10c étage, chambre 56, le SEPTIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de l'avant - midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Provinciale, Paul St-Martin.Montréal, ce 25 avril 1974.57116-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District of Montréal ( pANADA PERMANENT No 05-016722-73X TRUST COMPANY, corps » politique et constitué, dûment constitué selon la loi, et ayant son siège social et son principal bureau d'affaires pour la province de Québec au 600 ouest, boulevard Dorchester, en les ville et district de Montréal, demanderesse, versus SAMUEL DRUKER, ès qualité, en sa qualité de syndic mandaté pour la faillite de JEAN MASSE, des ville et district de Montréal, défendeur.« Un emplacement situé en la ville de Saint-Michel, sur le boulevard Saint-Michel, mesurant vingt-huit pieds de largeur sur une profondeur de cent sept pieds, connu et désigné comme le lot de subdivision numéro sept cent treize du lot originaire numéro quatre cent quarante-six (446-713), aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sault-au-Récollet; Avec circonstances et dépendances et tous les bâtiments construits y dessus, en particulier une maison portant les numéros civiques 7065, 7065A, 7067 et 7067A, boulevard Saint-Michel, dont les deux murs de côté sont mitoyens avec la propriété voisine.Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.02-065 478-72 .( T>P PETROLES LIMITEE, 18-000 357-740X O plaintiff, n ADMIRAL I CONSTRUCTION CO.LTD.defendant.\"An immoveable known and described as being subdivision three hundred ninety-nine (399) of original lot seventy-two (72) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Montreal, Montreal Registration Division, located on Aldred Crescent Street, in the Town of Hampstead, District of Montreal\".To be sold at the Sheriff's Office, in the Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th floor, room 56, on the SEVENTH day of JUNE, 1974 at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Provincial Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 25, 1974.57116 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal { pANADAPERMANENT No.05-016722-73.S TRUST COMPANY, a body I politic and corporate, duly incorporated according to law, and having its head office and principal place of business for the Province of Québec at 600 Dorchester Blvd.West, in the City and District of Montreal, plaintiff, vs SAMUEL DRUKER ès qualité, in his quality as Trustee to the assignment in bankruptcy of JEAN MASSE, of the City and District of Montreal, defendant.\"An emplacement situated in the Town of St.Michel, on St.Michel Boulevard, measuring twenty-eight feet in width by one hundred and seven feet in depth, known and designated as subdivision lot number seven hundred and thirteen of original lot number four hundred and forty-six (446-713), on the plan and book of reference of the Parish of Sault-au-Récollet; With the appurtenances and dependencies and all the buildings thereon erected, especially a house bearing civic numbers 7065, 7065A, 7067 and 7067A St.Michel Boulevard, both side walls whereof are mitoyen with the adjoining property. 3394 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4.1974, Vol.106, No.18 Toutes les dimensions ci-dessus sont en mesure anglaise et plus ou moins.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice en la ville de Montréal, 10, rue Craig est, 10e étage, chambre 56, le CINQUIÈME jour du mois de JUIN 1974, à ONZE heures de lavant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 24 avril 1974.57121 All the above measurements are English measure and more or less.\" To be sold at the Sheriff's Office Montreal Court House.10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FIFTH day of JUNE 1974, at ELEVEN o' clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 24, 1974.57l21-o Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal I T\\AME MAGDA NELSSON, No 05-002 473-73.S secrétaire, de la ville de ' Roxboro.district de Montréal, et v résidant au 27, 5e Avenue sud, demanderesse, r* LES HERITIERS DE FEU NIKOLAUS SZYMYLO, de la ville de Roxboro.district de Montréal, ayant déjà résidé au 27, 5e Avenue sud, défendeurs.Conformément au jugement de l'Honorable Juge Laurent E.Bélanger, de la Cour Supérieure pour le district de Montréal, en date du 8e jour de février 1974, ordonnant la licitation de l'immeuble ci-après décrit.« Un immeuble sis à Roxboro, dans le comté de Jacques-Cartier, connu et désigné sous le numéro deux cent quatre-vingt-un de la subdivision du lot originaire numéro quarante-huit (48-281) aux plan.et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Geneviève, dans ledit comté de Jacques-Cartier.Avec une bâtisse y érigée.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le CINQUIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 25 avril 1974.57117-0 Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal I X/fRS.MAGDA NELSSON, No.05-002 473-73.S secretary, of the Town of I Roxboro, District of Montreal, and residing therein at 27-5th Avenue South, plaintiff.is THE HEIRS OF THE LATE NIKOLAUS SZY-MYLO, of the Town of Roxboro, District of Montreal, having formerly resided at 27-5th Avenue South, defendants.In conformity with a judgment rendered by the Honourable Justice Laurent E.Bélanger, of the Superior Court for the District of Montreal, dated the 8th day of February 1974, ordering the licitation of the immoveable hereinafter described.\"An immoveable located in Roxboro, in the County of Jacques-Cartier, known and described as number two hundred eighty-one, subdivision of original lot number forty-eight (48-281) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Geneviève, in the said County of Jacques-Cartier.With a building erected thereon.\" To he sold at the Sheriff's Office, at the City of Mont-treal Court House.10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56.on the FIFTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 25, 1974.57117 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( /-1AISSE POPULAIRE ST-No 05-000 674-745.< ^ VINCENT FERRIER ' ayant son siège social au 205 est, nie Jarry, dans les cité et district de Montréal, demanderesse, m CÉCILE CAMBOURIEU, ménagère, épouse séparée de biens de René Cambouricu, résidant et domiciliée au 1065 rue St-Viateur, dans les cité et district de Montréal, défenderesse.« Un immeuble ayant front à l'avenue Chateaubriand, en la ville de Montréal, connu et désigné sous le numéro deux cent quatre-vingt-neuf (289) de la subdivision officielle du lot numéro sept (7-289) aux plan et livre de renvoi officiels du Village de la Côte St-Louis.Avec toutes les bâtisses y élevées et notamment une maison portant les numéros civiques 6393, 6395, 6397 de ladite avenue Chateaubriand.Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal l f\"*1 AISSE POPULAIRE ST.No.05-000 674-745.{ VINCENT FERRIER.' having its head office at 205 Jarry Street East, in the City and District of Montreal, plaintiff, vs CÉCILE CAMBOURIEU, housewife, separate as to property from René Cambourieu, residing and domiciled at 1065 St.Viateur Street, in the City and District of Montreal, defendant.\"A building fronting on Chateaubriand Avenue, in the City of Montreal, known and described as being lot number two hundred eighty-nine (289) of the official subdivision of lot number seven (7-289) on the official plan and in the book of reference for the Village of Côte St.Louis.With all buildings erected thereon, namely a house bearing civic numbers 6393, 6395, 6397 of said Chateaubriand Avenue. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i mai 1974, 106' année, n° 18 3395 Ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives apparentes et occultes, attachés audit immeuble.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le SIXIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de 1' avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 24 avril 1974.57118-o Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( TNAME LUCILA MARTEN, No 05-005323-72.-C DAME MARIA RECAL-' DE, demanderesses, vs DESMOND E.BEAMENT, défendeur.« Un emplacement ayant front rue Richardson, en la cité de Montréal, P.Q., connu et désigné sous les lots originaires numéros neuf cent cinquante-neuf et neuf cent soixante (959 et 960) aux plan et livre de renvoi officiels du Quartier Ste-Anne, mesurant ledit emplacement soixante et douze pieds de largeur par cent six pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins; Avec la bâtisse dessus érigée portant les numéros civiques 1930 à 1942 de ladite rue Richardson.Avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble.Avec droit de passage dans toutes les ruelles y attenantes tel que le tout se trouve actuellement sans exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Jus.ice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le QUATRIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 24 avril, 1974.57122-0 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / /~\\TTAVIO POLONIA, entre-Cour Supérieure,) ' preneur de Ste-Foy, district No 16-960.1 de Québec, versus LES IMMEU-{ BLES BOVAR INC., corps politique légalement constitué ayant une place d'affaires à Notre-Dame-des-Laurentidcs, rue des Bouleaux, district de Québec et PAUL GINGRAS et GÉRALD ROBI-TAILLE, syndics, GINGRAS & ROBITAILLE ès qualité des syndics dans la faillite Immeubles Bovar inc., 425 est, boulevard Charest, Québec et G.J.P.HOLDING LTD., corporation légale ayant son siège social et une place d'affaires au numéro 1435, boulevard d'Auteuil, Duvernay, district de Montréal et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.As the whole now subsists, with all active and passive, apparent or unapparcnt servitudes attaching thereto.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the SIXTH day of JUNE, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 24, 1974.57118 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( \\/fRS.LUCILA MARTEN, No.05-005323-72X -LV1 MRS.MARIA RECALDE, I plaintiffs, vs DESMOND E.BEAMENT, defendant.\"An emplacement fronting on Richardson Street, in the City of Montreal, P.Q., known and described as original lots numbers nine hundred fifty-nine and nine hundred sixty (959 and 960) on the official plan and in the book of reference for the Ste.Anne Ward, said emplacement measuring seventy-two feet in width by one hundred and six feet in depth, English measure, more or less; With building erected thereon bearing civic numbers 1930 to 1942 of said Richardson Street.With all active or passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveable.With a right of way in all the adjoining lanes thereto as the whole now subsists without exception or reservation.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the FOURTH day of JUNE, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 24, 1974.57122 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit :( (\"YTTAVIO POLONIA, con-Superior Court, J ^\u2014' tractor, of Ste.Foy, District No.16-960.) of Québec, versus LES IMMEU-l BLES BOVAR INC., a body politic and corporate having a place of business in Notre-Dame-des-Laurentides, Des Bouleaux Street, District of Québec and PAUL GINGRAS and GERALD ROBITAILLE, trustees, GINGRAS & ROBITAILLE in their capacity as trustees assigned for the bankruptcy of Immeubles Bovar inc., 425 Charest Boulevard East, Québec, and G.J.P.HOLDING LTD., a corporation legally incorporated having its head office and a place of business at 1435 d'Auteuil Boulevard, Duvernay, District of Montreal and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause. 3396 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 a) Propriété de Les Immeubles Bovar inc.: * La resuddivision 70 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-70); la subdivision 1 de la resubdivision 69 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-69-1); la subdivision 19 du lot originaire 285 (285-19); la subdivision 18 du lot originaire 286 (286-18).Tous lots du cadastre officiel pour la paroisse de Charles-bourg, division d'enregistrement de Québec, avec bâtiments dessus construits, circonstances et dépendances.» b) Propriété de G.J.P.Holding Ltd.: « La resubdivision 71 de la subdivision 8 du lot originaire 279 (279-3-71); la subdivision 1 de la resubdivision 18 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-18-1); la subdivision 2 de la resubdivision 74 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-74-2); la resubdivision 73 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-73); la resubdivision 72 de la subdivision 3 du lot originaire 279 (279-3-72) ; tous lots du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec, avec bâtiments dessus construits, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, le ONZIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de lavant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 29 avril 1974.57129-0 (a) Property of Les Immeubles Bovar inc.: \"Resubdivision 70 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-70); subdivision 1 of resubdivision 69 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-69-1); subdm-sion 19 of original lot 285 (285-19); subdivision 18 of original lot 286 (286-18).AU said lots on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" (6) Property of G.J.P.Holding Ltd.: \"Resubdivision 71 of subdivision 8 of original lot 279 (279-3-71); subdivision 1 of resubdivision 18 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-18-1); subdivision 2 of resubdivision 74 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-74-2) ; resubdivision 73 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-73) ; resubdivision 72 of subdivision 3 of original lot 279 (279-3-72) ; all said lots on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the ELEVENTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 29, 1974.57129 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( pHARLES E.MARCHAND, do-Cour Supérieure, J ' micilié et résidant à 880, rue No 10-413-F.J Dessane.Québec, district de Québec [ vs GRÉGOIRE BELLA VANCE, c.a.en sa qualité de syndic à l'actif de Gosselin Construction Inc., 71 rue St-Pierre, Québec, et LE REGIS-TRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Deux parcelles de terrain connues comme étant partie des lots numéros treize des subdivisions du lot originaire six cent trente-six (636-13 ptie n.s.) et trois des subdivisions du lot originaire six cent quarante-huit (648-3 ptie n.s.) du cadastre officiel de la paroisse de St-Ambroise, division d'enregistrement de Québec, plus amplement décrites comme suit, savoir: Parcelle « A » de figure irrégulière, bornée vers le nord-est, l'est et le sud-est par le lot 648-3-2 (rue), vers le sud-est par le lot 636-13-53 (rue), vers le sud-ouest par le lot 636-13-58-1, vers le nord-ouest par le lot 636-13 (n.s.) ; mesurant cent cinq pieds et deux dixièmes (105.2') au nord-est, trente et un pieds et quatre dixièmes (105.2') au nord-est, trente et un pieds et quatre dixièmes (31.4') le long d'une courbe de vingt pied9 (20 ) de rayon à l'est quatre cent soixante-quatre pieds et un dixième (464.1) au sud-est, cent trente et un pieds et six dixièmes (131.6') au sud-ouest, cinq cent trente pieds (530') au nord-ouest, contenant en superficie soixante-trois mille cinq cent trente-neuf pieds carrés (63,539 p.c), mesure anglaise.Fieri Facias de Terris Québec, to wit: IÇ^ HARLES E.MARCHAND, Superior Court, ) ' domiciled and residing at 880 No.10-413-F.) Dessane Street, Québec, District of l Québec, vs GRÉGOIRE BELLA-VANCE, c.a.in his capacity as public trustee for the account of Gosselin Construction Inc., 71 St.Pierre Street, Québec, and THE REGISTRAR of the Québec Registration Division, mis en cause.\"Two parcels of land known as being part of lots numbers thirteen of the subdivisions of original lot six hundred thirty-six (636-13 pt.n.s.) and three of the subdivisions of original lot six hundred forty-eight (648-3 pt.n.s.) on the official cadastre for the Parish of St.Ambroise, Québec Registration Division, more fully described as follows: Parcel \"A\" of irregular configuration, bounded towards the northeast, the east and the southeast by lot 648-3-2 (street), towards the southeast by lot 636-13-53 (street), towards the southwest by lot 636-13-58-1, on the northwest by lot 636-13 (n.s.); measuring one hundred five and two tenths feet (105.2') on the northeast, thirty-one and four tenths feet (31.4') along a curve having a radius of twenty (20') feet on the east, four hundred sixty-four and one tenths feet (464.1') on the southeast, one hundred thirty-one and six tenths feet (131.6') on the southwest, five hundred thirty feet (530') on the northwest, covering an area of sixty-three thousand five hundred thirty-nine square feet (63 539 sq.ft.) English measure. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n\" 18 3397 Parcelle « B » de figure irrégulière, bornée vers le nord-est par les lots 648-3-7-2 et 648-3-8-1, vers le sud-est par le lot 648-3-3 (rue), vers le sud-est, le sud, le sud-ouesl, l'ouest et le nord-ouest par le lot 636-13-53 (rue), vers le nord-ouest par le lot 648-3-2 (rue); mesurant cent dix pieds et quatre dixièmes (110.4') et cent dix-sept pieds et huit dixièmes (117.8') au nord-est, cent trente et un pieds et neuf dixièmes (131.9') et quatre cent trente pieds (430') au sud-est, trente et un pieds et quatre dixièmes (31.4') le long d'une courbe de vingt pieds (20') de rayon au sud, cent quatre-vingt-dix pieds (190') au sud-ouest, trente et un pieds et quatre dixièmes (31.4') le long d'une courbe de vingt pieds (20') de rayon à l'ouest, quatre cent soixante-quatre pieds et un dixième (464.1') et quarante-quatre pieds et sept dixièmes (44.7') le long d'une courbe de quatre-vingt-pieds (80') de rayon au nord-ouest; contenant en superficie cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix neuf pieds carrés (129,579 p.c.) mesure anglaise.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, le CINQUIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 29 avril 1974.57119 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / \"\"TRUST GENERAL DU CANA-Cour Supérieure.) * DA, corporation légalement No 14-594 J constituée, ayant une place d'affai-\\ res à 1091, Chemin St-Louis, Québec 6, vs TAVERNE COLONIALE INC., corporation légalement constituée, avant une place d'affaires au 1087, rue St-Jean, Québec et RICHARD LÉGARÉ, domicilié au 4, Parc Samuel Holland, app.1607, Québec et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec; mis en cause.« Un emplacement situé en la cité de Québec, sur le côté sud de la rue St-Jean, mesurant environ trente-deux pieds et quatre pouces (32'4\") de front sur environ quatre-vingt-dix-sept-pieds (97') de profondeur, plus ou moins, faisant partie du lot numéro deux mille sept cent quatre-vingt-dix sept (2797 Ptie) du cadastre du Quartier St-Louis, Québec, avec la bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, notamment la bâtisse située à 1087-1091, rue St-Jean, Québec; avec la mitoyenneté dans le pignon qui sépare cette propriété de celle construite sur le lot numéro deux mille sept cent quatre-vingt-seize (2796) du même cadastre; avec droit à la servitude de passage à pied et en voiture sur le lot numéro deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (2798) dudit cadastre pour communiquer de l'immeuble à la rue St-Stanislas et vice versa; avec en plus les droits de mitoyenneté avec le lot voisin numéro deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (2798) du même cadastre; ledit immeuble porte le numéro civique 1087 de la rue St-Jean à Québec.» Parcel \"B\" of irregular configuration, bounded towards the northeast by lots 648-3-7-2 and 648-3-8-1, towards the southeast by lot 648-3-3 (street), towards the southeast, the south, the southwest, the west and the northwest by lot 636-13-53 (street), towards the northwest by lot 648-3-2 (street); measuring one hundred ten and four tenths feet (110.4') and one hundred seventeen and eight tenths feet (117.8') on the northeast, one hundred thirty-one and nine tenths feet (131.9') and four hundred thirty feet (430') on the southeast, thirty-one and four tenths feet (31.4') along a curve having a radius of twenty (20') feet on the south, one hundred ninety feet (190') on the southwest, thirty-one and four tenths feet (31.4') along a curve having a radius of twenty (20') feet on the west, four hundred sixty-four and one tenth feet (464.1') and forty-four and seven tenths feet (44.7') along a curve having a radius of eighty (80') feet on the northwest; covering an area of one hundred twenty-nine thousand five hundred seventy-nine square feet (129, 579 sq.ft.) English measure.With buildings erected thereon appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the FIFTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 29, 1974.57119 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / pENERAL TRUST OF CANADA, Superior Court.) a corporation legally incorpora- No 14-594 J ted, having a place of business at 1091 \\ Chemin St.Louis, Québec 6, vs TAVERNE COLONIALE INC., a corporation legally incorporated, having a place of business at 1087 St.Jean Street, Québec and RICHARD LÉGARÉ, domiciled at 4, Samuel Holland Park, Apt.1607, Québec and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause.\"An emplacement located in the City of Québec, on the south side of St.Jean Street, measuting approximately thirty-two feet and four inches (32'4\") in front by approximately ninety-seven feet (97') in depth, more or less, being part of lot number two thousand seven hundred ninety-seven (2797 Pt) on the cadastre for St.Louis Ward, Québec, with the building erected thereon, appurtenances and dependencies, namely the building located at 1087-1091 St.Jean Street, Québec; with joint ownership of the gable wall which separates this property from the one built on lot number two thousand seven hundred ninety-six (2796) of the same cadastre; with servitude of right of way for pedestrians and vehicles on lot number two thousand seven hundred ninety-eight (2798) of the said cadastre in order to communicate from the building tô St.Stanislas Street and vice-versa; furthermore with rights of joint ownership with the neighbouring lot, number two thousand seven hundred ninety-eight (2798) of the same cadastre; the said building bears civic number 1087 on St.Jean Street in Québec.\" 3398 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, fol- !r>.N°- 28 Pour être vendu au bureau du Shérif de Québec, Palais de Justice, Québec, le TREIZIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 29 avril 1974.57125-o Fieri Facial de Terril Québec, à savoir: I p AISSE POPULAIRE DE SIL-Cour Supérieure.J 'LERY, corps politique et incor-No 16-944 J poré légalement constitué ayant une \\ place d'affaires dans les cité et district de Québec, vs GÉRARD PROULX, homme d'affaires domicilié à 3333, rue Brouage, Ste-Foy, Québec, district de Québec.« Le lot No trois cent quatre-vingt-un (381) des subdivisions du lot originaire No quatre cent trois (403-381) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Foy, maintenant ville de Ste-Foy, division d'enregistrement de Québec\", avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le SIXIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shfrif adjoint, Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 29 avril 1974.57123-o Fieri Facias de Terril Québec, à savoir: / p UV PAQUET.domicilié au 4650, Cour Provinciale) *J Ave.de Gaulle, app.7, Char-No 104-268.J lesbourg, district de Québec et Dame \\ SIMONE FILTEAl\" LAGACÉ, domiciliée au 139, ave.St-Joseph, à Beauport, district de Québec.« Les immeubles connus et désignés comme étant les lots huit cent quatorze subdivision soixante-douze (814-72), huit cent quinze subdivision vingt-neuf (815-29), huit cent seize subdivision deux de la subdivision sept (816-7-2) du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, avec bâtisses, circonstances et dépendances dessus construites.» \u2022 Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le DIXIÈME jour de .TUIN 1974, à DIX heures de l'avant-midi./,« shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 29 avril 1974.57124-o TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District d'Arthabaska ( tSaME MARIE CLAIRE HUPPE, do-No I8-800X raiciliée à 273.rue Biais.Victoria-v ville, demanderesse, vs MARCEL TOU-RIGNY, domicilié à Appartements Roger, rue Hart, Trois-Rivières, défendeur.To be sold at the Office of the Shenff of ^ébec, at the Court House.Québec, on the THIRTEENTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriffs Office, Assistant Sheriff.Québec, April 29, 1974.57125 Fieri Facias de Terris Québec, to wit:/PAISSE POPULAIRE DE SIL-Superior Court.) LERY, a body politic and legal- No.16-944 J ly incorporated having its place of I business in the City and District of Québec, vs GÉRARD PROULX, businessman domiciled at 3333 Brouagc Street, Ste.Foy, Québec, District of Québec.\"Lot number three hundred eighty-one (381) of the subdivisions of original lot number four hundred and three (403-381) on the official cadastre for the Parish of Ste.Foy, now the City of Ste.Foy, Québec Registration Division; with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street.Québec, on the SIXTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 29, 1974.57123 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / pUY PAQUET, domiciled at 4650 Provincial Court) de Gaulle Ave., Apt.7, Char- No.104-268.\\ lesbourg, District of Québec, vs Mrs.K SIMONE FILTEAU LAGACÉ, domiciled at 139 St.Joseph Ave., in Beauport, District of Québec.\"The immoveables known and described as being lots eight hundred and fourteen, subdivision seventy-two (814-72), eight hundred and fifteen, subdivision twenty-nine (815-29), eight hundred and sixteen, subdivision two of subdivision seven (816-7-2) on the official cadastre for the Parish of Beauport, with buildings, appurtenances and dependencies erected thereon.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the TENTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, April 29, 1974.57124 TROIS-RIVIÈRES Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Arthabaska / A/1HS MARIE CLAIRE HUPPE, No.18-800.\"S j-vx domiciled at 273 Biais Street, Vic-l toriaville, plaintiff, w MARCEL TOU-RIGNY, domiciled at Appartements Roger, Hart Street, Trois-Rivières, defendant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n' 18 3399 « Un terrain-emplacement, situé en la paroisse de St-Jean-Baptiste-de-NicoIet, en bordure du fleuve St-Laurent, connu et désigné comme étant le lot numéro dix-sept, subdivision du lot originaire numéro dix (10-17) du cadastre officiel de la paroisse de St-Jean-Baptiste-de-Nicolet, comté de Nicolet; ce terrain mesure cinquante pieds (50') dans ses lignes nord-ouest et sud-est, soixante-dix-sept pieds (77') dans la ligne nord-est et soixante-dix-neuf pieds et six dixièmes (79.6') dans la ligne sud-ouest, à mesure anglaise, avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, et avec aussi toutes les servitudes actives, passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Nicolet, division No 2, 395, rue Courchesne, Nicolet, MERCREDI, le DIXIÈME jour du mois de JUIN 1974, à TROIS heures de l'après-midi.Le shérif adjoint, Trois-Rivières, Fernande Turgeon.17 avril 1974.57115-o \"An emplacement, located in the Parish of St.Jean-de-Nicolet, bordering on the St.Lawrence River, known and described as being lot number seventeen, subdivision of original lot number ten (10-17) on the official cadastre for the Parish of St.Jean-Baptiste-de-Nicolet, County of Nicolet; said emplacement measures fifty feet (50') on its northwest and southeast lines, seventy-seven feet (77') on its northeast Une and seventy-nine and six tenths feet (79.6') on its southwest line, EngUsh measure, with all buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, and also with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said immoveables.\" To be sold at the Nicolet Registry Office, Division No.2, 395 Courchesne Street, Nicolet, on WEDNESDAY, the TENTH day of JUNE, 1974, at THREE o'clock, in the afternoon.Fernande Turgeon, Trois-Rivières, Assistant Sheriff.April 17, 1974.57115 3400 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 INDEX No 18 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES C.A.C.Funds-Realty Limited (Permit-License).3376 Club Oriskany inc.(Lc) (Dissolution).¦ \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 ¦ \u2022 -.- \u2022 ¦ ¦ \u2022¦\u2022 ¦ ¦ ¦ ¦.«76 Conseil No 6272 Mgr.Papineau des Chevaliers de Colomb de Notre-Dame des Prairies (Le) (Const.).3376 Estate of Serge Kazanovitch (Benefit of Inventory).3375 Fabrique de la paroisse Ste-Bernadette-de-Pellegrin (La) (Dissolution).3377 Fabrique de la paroisse St-Gabriel-de-Rameau (La) (Dissolution).3377 Fabrique de la paroisse St-Jean-de-Brébeuf (La) (Dissolution).3377 Fabrique de la paroisse St-Octavc-de-l'Avenir (La) (Dissolution).3378 Fabrique de la paroisse Sacré-Coeur des Landes (La) (Dissolution).33/7 Mgr.Papineau Council No.6272 of the Knights of Columbus of Notre-Dame-des-Prairies (Const.).3376 Marcana Resources Limited (Permis-License).522 Oriskany Club Inc.(The) (P.L.).3376 Succession Serge Kazanovitch (Bénéfice d'inventaire).3375 CHANGEMENT DE NOM \u2014Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Bonin, Suzanne.3378 Dennis, Gerard John.3378 Johnson, Steven Paul.3378 Lodi, Sasha Tutu.3379 Miller, William.3379 St.Pierre.Carmen.3379 Shears, Philip.3379 Shears, Wendy Sue.3379 Watson, Donald.3379 Demandes: Applications: Arditi, Elias.3375 Jean, Joseph, Dollard, Irene.3374 Scantlebury, Courtney Fitzgerald.3375 COMMISSION COMMISSION COMPAGNIES\u2014 COMPANIES Commission Québec Transport ''OI DES ACT des transports du Québec Commission Abandon Surrender Avis de la Commission « proprio motu ».3333 de charte of Charter Avis de décision, rendues.3361 Auberge du Coteau (Corporation) (L').3328 Avis de désistement.3361 n i _i ci \u2022 f il r .j ,\u201e\u201e Avis d'introduction de requêtes.3334 S\"*\"?* ShoPP'ng Center Ltd.3328 Notice \"proprio motu\" by the Commission.3333 Centre d Achate Boulevard ltée.3328 Notice of decisions rendered.3361 Chouinard & Associés me.3328 Notice of withdrawal.3361 Dagenais Realties Ltd.3328 Notice of submission of applications.3334 Gendreau (Irène) inc.3328 Immeubles Dagenais ltée.3328 gO^ACgnES EXTRA-PROVINCIAL Joeda Investment Corp.3328 ÉTRANGÈRES COMPANIES Kempner Limited.3328 Permis: Licenses: Meralda Ltd.3328 Compagnie d'approvisionnement Général du Placements Bernard Courtemanche ltée.3328 ^ Canada (1973) limitée (La).3390 PlacementsRosaireCourtemanclielt.ee.3328 Gateway Service Ltd.3390 Rosa Holdings Inc.3328 General Supply Company of Canada (1973) Roux (Albert) limitée.3328 Limited (The).3390 Rouyn MeUl Corporation.3328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n° 18 3401 Changement de nom Change of name Barber (Ross H.) & Associates Ltd.3330 Barber (Ross H.) & associés ltée.3330 Bois de construction M.Longpré inc.3330 Compagnie Maurice & Claude ltée (La).3330 Construction Terrac inc.3330 Editions Fleur de Lys ltée (Les).3331 Fleur-de-Lys Publications Ltd.3331 Immeubles Télé-Capitale ltée.3331 Lanix inc.3331 Longpré (M.) Lumber Inc.3330 Oria ltée.3331 Pitti Restaurant Ltd.3331 Restaurant Pitti ltée.3331 Transport Baie des Chaleurs incorporée.3331 Trolec inc.3331 Demande d'abandon Application for de charte Surrender of Charter German-Canadian Import Company.3380 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part /) A.G.A.P.Investments Inc.3324 Agence de voyages Vienar inc.3324 Appareils électroniques Sésame inc.3324 Ateliers de St-Alexandre inc.(Les).3324 Audet (F.) Transport inc.3327 B.F.D.Products Limited.3324 Beteli Inc.3324 Boutique du cuir Maurice inc.3325 Boutique Le Monde de la Caméra ltée.3325 Boutique Port de Mer inc.3325 Boyce (James) Inc.3325 Brasserie centrale d'Asbestos inc.3325 Brasserie Mont-Laurier inc.3325 C.L.M.Sport Inc.3325 Camera World Shop Ltd.3325 Canametal Inc.3325 Centre d'auto Monière inc.3325 Centre de physiothérapie Pierrefonds-Vau- dreuil inc.3325 Century Fabrics Ltd.3327 Comett Leasing Ltd.3326 Communications Flo ltée.3326 Construction G.Poulin ltée.3325 Construction J.P.Marceau inc.3325 Continental Store (Charlesbourg) Ltd.3326 Continental Store (St-Georges) Ltd.3326 Corporation d'aménagement I.M.A.(La).3325 Courchesne & frères inc.3325 Ecuries L.& P.ltée (Les).3325 Elgi Imports Inc.3325 Empire Ethnic Pageantrys Inc.3325 Entreprises de maintenance Transparent inc.3327 Entreprises électriques Buckland inc.(Les).3325 Entreprises Jean-Guy Lampron inc.(Les).3325 Entreprises Lagrois inc.(Les).3325 Entreprises Richard Gagnon inc.(Les).3326 Entreprises Triton inc.(I-es).3326 Entreprises Vasibal inc.(Les).3326 Fastes ethniques Empire inc.(Les).3325 Ferme G.F.Fortin ltée.3326 Ferme Hervieux inc.3326 Fleuriste Lyse-Anne inc.3326 Flo Communications Ltd.3326 France Square Investments Inc.3327 Frigobec limitée.3326 Garage A.Vaillancourt et L.Gosselin inc.3326 Hervieux Farm Inc.3326 I.M.A.Development Corp.3325 Importations Elgi inc.(Les).3325 Industries Ness ltée (Les).3326 Industries Porkiri ltée (Les).3326 Installations électriques B.Roussel Rivière-du-Loup ltée.3326 Investissements A.G.A.P.inc.(Les).3324 Johnson, Dubois & Associates Inc.3326 Johnson, Dubois & Associés inc.3326 L.& P.Stables Ltd.3325 Lafrenière & Paquette limitée.3326 Lauzière & Martel inc.3326 Locations ComeU ltée (Les).3326 Logetex Inc.3326 Lord (Claude) Fashions Inc.3327 Lyse-Anne Florist Inc.3326 Magasin Continental (Charlesbourg) ltée.3326 Magasin Continental (St-Georges) ltée.3326 Magnum Marketing Inc.3326 Marceau (J.P.) Construction Inc.3325 Marché Duberger inc.3327 Mirabel Fashions Inc.3327 Mireault Auto Spring Inc.3327 Modes Claude Lord inc.3327 Monière Auto Center Inc.3325 Montego Drapery Fabrics Inc.3327 Morin (T.) Transports Inc.3327 Ness Industries Ltd.33*6 Pauzé (François) inc.3327 Pierrefonds-Vaudreuil Physiotherapy Center Inc.3325 Placements France Square inc.(Les).3327 Poulin (G.) Construction Ltd.3325 Pratt (Marcel) inc.3327 Produits Agrob inc.(Les).3327 Produits B.F.D.limitée (Les).3324 Produits M.S.inc.3327 Ressorts Mireault inc.(Les).3327 Restaurant sans non inc.3327 Services immobiliers L.J.M.inc.(Les).3327 Société de mercatique Magnum inc.3326 Société Mynor inc.3327 Sport C.L.M.inc.3325 Tardif (Claude) inc.3327 Temairlnc.3327 Tissus de tentures Montego inc.3327 Tissus Siècle liée (Les).3327 Transparent Maintenance Enterprises Inc.3327 Transport F.Audet inc.3327 Transports T.Morin inc.(Les).3327 Trenyco inc.3327 3402 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 Lettres patentes Letters Patent (1- partie) (Part /) (suite) (continued) Triton Enterprises Inc.3326 Vêtements de modes Mirabel inc.(Les).3327 Vienar Travel Agency Inc.3324 Vitrerie Angelo Saran Inc.3328 Voybeclnc.3328 Lettres patentes Letters Patent (3- partie) (Part IIP) Amis du hockey de Ragueneau inc.(Les).3329 Artisans de la coulée d'art incorporée (Les).3329 Association des arbitres du hockey de Pointe- Gatineau inc.3329 Association des jeunes de St-Bruno inc.3329 Association des laboureurs de Pontiac inc.(L').3330 Association des propriétaires de la terrasse Comeau inc.(L').3329 Bureau de la Communauté Chrétienne des Haïtiens de Montréal.3329 Club de l'Age d'Or de Ste-Angèle-de-Laval inc.(Le).3329 Club de moto Hondix inc.3329 Club des dames auxiliaires Vincentini de Montréal inc.3329 Club folklorique Furlan de Montréal inc.3329 Comité d'organisation de la rencontre internationale des animateurs francophones de 1974 inc.3329 Conseil juif de publication et de presse Terezin 3329 Furlan Folkloric Club of Montreal Inc.3329 Hondix Moto Club Inc.3329 Jewish Publication Council and Terezin Press 3329 Ligue de hockey majeure juvénile de Montréal 3329 Ligue de taxi de Granby inc.(La).3329 Ligue de taxis de Mont-Joli (La).3329 Ligue de taxis de Montréal inc.(La).3329 Ligue de taxis de St-Hyacinthe inc.(La).3330 Loisirs de Fleurimont inc.3330 Montreal Juvenile Major Hockey League.3329 Organisation philantropique grecque d'aide mutuelle de Montréal.3330 Pontiac Plowmen Association Inc.(The).3330 Régionale des jeunes chambres des cantons de l'Est inc.(La).3330 St-Bruno's Youth Association Inc.3329 Service des loisirs St-Elzéar de Laval.3330 Service populaire d'entraide mécanique de Québec.3330 Télévision communautaire de Granby inc.3330 Télévision éducative et communautaire du Saguenay ltée (La).3330 Théâtre Balagan.3330 Vicentini Ladies Auxiliaries Club of Montreal Inc.3329 Village minier Boulamaque inc.(La).3330 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Bédard, Dodge Chrysler ltée.3331 Construction Dal Bec inc.3331 Gaudet (Alexandre) limitée.3331 Legatee inc.3331 Manach (A.) Inc.3331 Pisapia Construction Inc.3331 DEMANDES À APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Boucherville, ville-town.3368 Kirkland, ville-town.3371 Lachine, cité-city.3370 La Prairie, ville-town.3372 LaSalle, cité-city.3373 Pierrefonds, ville-city.3369 Verdun, cité-city.3371 MINISTÈRE DEPARTMENT Affaires municipales Municipal Affairs Pointe-Calumet, village (Amend.).3391 PROCLAMATIONS PROCLAMATIONS Coming into force of the official cadastre of a part of the parish of St.Alphonse situated in the registration division of Chicoutimi.3382 Coming into force of the official cadastre of a part of the Seigr.eury of Terre-Ferme-de-Mingan, situated in the registration division ofSept-ÏIes.3381 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie de la paroisse Saint-Alphonse, située dans la division d'enregistrement de Chicoutimi.3382 Mise en vigueur du cadastre officiel d'une partie de Ta seigneurie de Terre-Ferme-de-Mingan située dans la division d'enregistrement de Sept-Iles.3381 Régie de l'Électricité Electricity et du Gaz and Gas Board Gaz Métropolitain, inc.(Requête-Pétition)____ 3392 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: Adjustment Bureau of Montreal Inc.3301 Aide aux étudiants du collège de la salle de Thetford-Mines inc.(L').3301 Air Mont-Laurier inc.3301 Alliance métropolitaine de la récréation.3301 Aluminum Containers Ltd.3301 Amel Paper Box Co.Ltd.3301 Ameublement Cité Jardin.3301 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n° 18 3403 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Association de commerces, industries et affaires de Saint-Tite (A.C.I.A.).3301 Association des diplômés du cours du soir en sciences comptables de la faculté de Commerce de l'Université Laval inc.(L').3301 Association des éducateurs du centre administratif (CECM) (L').3301 Association des épiciers-restaurateurs du coin du comté Jonquière-Kénogami inc.(L') .3301 Association des petits commerçants de la ville de Hull (L').3301 Association des propriétaires du chemin du baume de terres rompues.3301 Association sportive d'Iberville inc.3301 Association des vétérans de tennis de la Mau- ricie inc.(L').3301 Atlas Detective Bureau Incorporated.3301 Auto Parc Riverside Inc.3301 Barbizon Mines Limited.3301 Bayshore Industries of Canada Ltd.3301 Bédard (J.C.) inc.3301 Belcraft Pants Co.Ltd.3302 Belle Handbags Co.(La).3302 Benefit Realty Corporation.3302 Benoit (J.R.) tailleur & valet service incorporé 3302 Bibliothèque des jeunes de Saintc-Agathe-des- Monts inc.(La).3302 Bijouterie Robert Jewellery Inc.3302 Binette (Ulric) & Fils, inc.3302 Boulet (Philippe) inc.3302 Brill Records & Music Inc.3302 Bromo Cedin ltée.3302 C.F.T.Construction Co.Ltd.3302 Cadets-Chevaliers Notre-Dame d'Asbestos inc.(Les).3302 Calumet Investments Limited.3302 Centrale sportive St-Georges inc.3302 Centre ouvrier de la Mauricie.3302 Chalifour (J.) & Fils inc.3302 Chambre de commerce des jeunes de Warwick inc.(La).3302 Chambre de commerce senior de St-Ferdinand (La).3302 Chantiers de Drummondville inc.(Les).3302 Charry Gowns Inc.3302 Cinéma Pocatière inc.3302 5-10-15 automobile limitée.3302 Clairmont Trading Inc.3302 Clix Fastener Corporation.3302 Club hippique de Québec liée (Le).3302 Club des pins de Rivière-du-Loup inc.3302 Club Richelieu Beloeil.3302 Club Richelieu Granby.^.3302 Club de ski de Malartic incorporée.3302 Club des zoulous de Ville St-Laurent.3302 Collège commercial Desmarais de Victoria-ville inc.3302 Comité des oeuvres de loisirs de St-Félicien inc.3302 Compagnie Fauchard ltée (La).3303 Comptoir industriel incorporée (Le).3303 Concord Plaza Merchants Association.3303 Confection moderne ltée.3303 Conseil supérieur de la chiropratique pour la province de Québec inc.3303 Continental Café Incorporated.3303 Continental Warehouse & Transfer Ltd.3303 Corporation des chemins d'hiver de Ste-Thècle 3303 Corporation minière Eastman inc.3303 Corporation Relex ltée (La).3303 Côté (Phil) Ltd.3303 Couture (Ferdinand) ltée.3303 De Villers (Paul) & Fils inc.3303 Delmont Investment Corporation.3303 DeSales Uranium Mining Corporation.3303 Desmarais automobile ltée.3303 Desruisseaux (L.) & L.P.Rhéault limitée.3303 Développements du moulin et de la rivière Jaune inc.(Les).3303 Di Pietro & Frères inc.(St-Catherine est).3303 Dominion Tile & Terrazo Co.Ltd.3303 Doucet (Arthur) limitée.3303 Drummond automobile inc.3303 Dufour & Dufour ltée.3303 E.C.Auto Rentals Ltd.3303 E.& M.Surgical Supplies Ltd.3303 Eastern Cereal Food Products Co.Ltd.3303 Ecole d'agriculture de Mont-Laurier (L').3303 Ecole Maimonide.3303 Editions de la Nouvelle-France inc.3303 EldonCo.Ltd.3303 Electro-Reagents (Québec) Limited.3303 Entreprises Edgar Nault ltée (Les).3303 Entreprises Le Prince inc.(Les).3303 Fanfare Val d'Or-Bourlamaque incorporée (La).3303 Fecteau & Nantel Plastic Neon Inc.3304 Federal Converters Company.3304 Fcrnhill Trading Corporation.3304 Financial Adjusters Ltd.3304 Fleuriste Madelon ltée.3304 Foamolate Products Ltd.3304 Four Sixty-Four St-Mathias Inc.3304 Frais funéraires Dupuis limitée (Les).3304 Fury Speed Way Company Ltd.3304 Gaouette & Fils inc.3304 Garage Fernand Tremblay limitée.3304 Garage Port-Cartier ltée.3304 Gaspé Gaz Utilités incorporée.3304 Gauthier (Jim) & Fils limitée.3304 Gourmet Publishing Co.Ltd.3304 Granby Construction ltée.3304 Granolux Québec Inc.3304 Gregory & Company Inc.3304 Guardian Furniture Sales & Services Inc.3304 Habitations Laprairie inc.(Les).3304 Harmonie de Disraeli (L').3304 Holpar Holdings & Development Corp.3304 3404 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May i.Mi, Vol.106, No.18 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Hôpital Notre-Dame-du-Sacré-Coeur.3304 Hôtel St-Louis (Rouyn) inc.3304 Ideal Dry Cleaners and Dyers Company Li-raited.3304 Imbo automobile inc.3304 Immeubles populaires inc.(Les).3304 Imperial Electrical Manufacturing & Contracting Co.3304 Industrial Supplies & Marine Equipment Limited.3304 Industries Causapscal ltée (Les).3304 Italian Immigrants' Assistance Centre.3304 Jacksey's Limited.3304 Janecroftlnc.3304 Jezzini Import Export Co.Ltd.3304 Johnson Fruit Inc.3304 Johnted Discount Ltd.3305 Laberge, inc.3305 Laval Baseball Association Inc.- 3305 Laval Fence (1969) Inc.3305 Laverie Apollo ltée.3305 Le Grand Fur Ltd.3305 Lessard Lumber Limited.3305 Letendre inc.3305 Ligue des propriétaires de Saint-Hyacinthe incorporée (La).3305 Limoges (A.& C.) inc.3305 Lobell Construction Company Limited.3305 Lowen-Ross Sales Inc.3305 Lumau Mining Corporation.3305 Magasin de la bonne cuisinière inc.(Le).3305 Malta B uilders Ltd.3305 Maplewood Provisions Inc.3305 Marathon Foods Inc.3305 Maribe ltée.3305 Marlowe Mines Limited.3305 Martineau (H.) Company.3305 Marvel Motor Sales Ltd.3305 McBain Automobile Transport Ltd.3305 Metal Treatments Inc.3305 Michael Knitting Mills Ltd.3305 Minua Construction Inc.3305 Montreal Editions Inc.3305 Montreal School Bus Owners Association Inc.3305 Moreau Péribonka Black Granite Inc.3305 Morin (E.) Construction inc.3305 Morrissette (A.R.) ltée.3305 Motel Mohawk inc.3305 Mount Pleasant Construction Company Limited.3305 Murray Bay Pulp & Paper Co.Ltd.3305 Nadeau (Robert D.) incorporée.3305 Nagley (George) Inc.3306 Nettoyeurs de bâtisses Clido ltée.3306 Noël & Grenier limitée.3306 Oeuvre des loisirs (L').3306 Oeuvre des terrains de jeux et des loisirs de Jacques-Cartier, inc.(L').,.3306 Office Partitions Incorporated.3306 Onassis & Onassis inc.3306 Ouellet incorporée.3306 Page & Lalonde Auto inc.3306 Panet Metals Corporation Ltd.3306 Paradis des dames inc.3306 Parkway Electric, Ltd.3306 Parti Civique de Hull inc.(Le).3306 Pâtisserie Jean & Jean (1969) inc.3306 Patro Notre-Dame de Charlesbourg.3306 Patrons des crèches de la Miséricorde (Les).3306 Pavillon Lacroix inc.(Le).3306 Paysagistes Laval inc.3306 Perfect Knitting Mills Ltd.3306 Perruquier de Granby inc.(Le).3306 Philip Furniture Frame Mfg.Co., Ltd.3306 Pinard (Aurel) limitée.3306 Pinnacle U Copper Corporation.3306 Place Pigalle inc.3306 Planned Development Co.Ltd.3306 Power (L.) & Company Limited.3306 Produits Brunet (1967) inc.(Les).3306 Prolab Construction ltée/Ltd.3306 Province of Québec Numismatic Association.3306 Publications Téléphonie ltée (Les).3306 Québec Developers & Smelters Limited.3306 Québec Motel Association Inc.3306 Québec Ungava Ore Development Corporation 3306 Raymond & Tousignant inc.3306 Réunion limitée.3307 Rivard (Claude) Limited.3307 Riverside Gold Mines Incorporated.3307 Robert (Catherine) Limited.3307 Robert Construction limitée.3307 Rosemère Inn Ltd.3307 Roslyn Holdings Ltd.3307 Ross (J.P.) Plastering Limited.3307 Rouyn-Noranda Automobiles Inc.3307 S.O.S.nouvelle demension inc.3307 Sabre construction inc.3307 Selected Investment Inc.3307 Semaine commerciales du jeune Commerce du Cap incorporée (Les).3307 Service d'ambulances des Laurentides ltée (Le) 3307 Service d'entretien Provost ltée.3307 Service de location de logements de Sherbrooke inc.3307 Service de sécurité Age inc.3307 Sherin Construction Co.3307 Sigma Game Club.3307 Smart Maid Hat Mfg.Inc.3307 Société d'expansion pharmaceutique inc.3307 Sommet suisse, ltée (Le).3307 Spécialités de danse tempo inc.3307 Sports Car Company Inc.(The).3307 Standard Agencies Acceptance Corporation.3307 Star Electric Inc.3307 Starr (Jack) Inc.3307 Steel & Graphite Co.Ltd.3307 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i mai 1974, 106' année, n° 18 3405 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Style Shop Clothes Limited.3307 Sunrise Spring Developments Limited.3307 Surfaces et produits de vinyl inc.3307 T.M.L.Enterprises Inc.3307 Talma Construction Ltd.3307 Talon Street Investment Corporation.3307 Taxi B.L.M.inc.3308 Temp-O-Lite Limited.3308 Terrebonne Titanium Co.Ltd.3308 Terrimlnc.3308 Tournoi international de hockey juvénile inc.3308 Townsite Builders Ltd.3308 Tratt Construction Co.Ltd.3308 Tremblay (E.-E.) ltée.3308 Unie Heating and Air Conditioning Limited.3308 VendriteLtd.3308 Victoria Copper Zinc Mines Ltd.3308 Walker (A.G.) & Co.Ltd.3308 Westwood Realties Ltd.3308 Whitton (J.V.) Construction ltée.3308 Yvcor Investments Inc.3308 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: A.J.P.Electronique inc.3308 A & R Mobile Transport Inc.3308 Agences d'assurance LaSale inc.(Les).3308 Amicale Mariste Beloeil inc.3308 Association des écoles de coiffure pour dames de la province de Québec (L').3308 Beaulieu (JJJ.) ltée.3308 Beaumanoir incorporée.3308 Bédé Auto inc.3308 BeUautoltée.3308 Boissy (A.) compagnie limitée.3308 Botany Hall Clothes Inc.3309 Boulevard Development Co.Inc.3309 Burners (I.C.) Ltd.3309 C.& N.Fish & Game Club Inc.3309 Casino Dress Inc.3309 Centre civique de Saint-Pau 1-de-Lavaltrie (Le) 3309 Cercle musical d'Acton Vale Inc.3309 Charlemagne Construction Inc.3309 Cie de mica de Mistassibi ltée (La).3309 Cie de navigation Gauthier inc.(La).3309 Cinq-O-ltée.3309 Coak(K&G)Co.3309 Club des ambassadeurs de Gatineau-Bucking- ham inc.3309 Club des employés de la compagnie électrique de Saguenay inc.3309 ClubTracadièche.3309 Compagnie de déblaiement des chemins d'hiver de Kamouraska inc.(La).3309 Compagnie Edouard Jutras limitée (La).3309 Compagnie d'imprimerie et de publication de la rive-sud limitée (La).3309 Compagnie Jean & Charles (La).3309 Compagnie de réfrigération nationale limitée.3309 Compagnie Roger Poitras Transport (La).3309 Connaught Country Club.3309 Consolidated Québec Yellowknife Mines Ltd.3309 Construction préfabriquée Tribic inc.3309 Cooper (Hy) inc.3309 Côte Vertu Riding School Inc.3309 Crane (Shirley) Inc.3309 D.S.& B.Enterprises Ltd.3309 Daigle & Ross limitée.3309 Daigneault (R.) ltée.3309 Dainty Dot Shoes Inc.3309 Da-Kerr-Ad Consolidated Mines Limited____ 3309 Daltner's Ltd.3309 Dan-D-Lax Corporation.3309 Dandy Pants & Sportswear Inc.3310 Daneau (G.) limitée.3310 Danel Sportswear Inc.3310 Danforth Import Export Inc.3310 Danis (J.) limitée.3310 D'Anjou (P.E.) & Fils limitée.3310 D'Argencourt inc.3310 Daruth Manufacturing Co.Ltd.3310 Daverna Mills Limited.3310 De Luxe Silks & Lingerie Ltd.3310 Debbage & Hewitson Inc.3310 Dechaux Brothers Limited-.3310 Defor Chicougamau Mines Limited.3310 Delisle (J.E.) inc.3310 Delormier Construction Ltd.3310 Delta Machine and Motor Company.3310 Demers (L.) & cie limitée.3310 Demers Transport ltée.3310 Denis Machine Shop Limited.3310 Depelteau (J.H.) inc.3310 Dependable Watchstraps Co.Ltd.3310 Deschênes Ratepayers Association (The).3310 Desjardins Express Inc.3310 Diamond Fur Blending Corp.(Canada).3310 Diamond (H.) & Sons Inc.3310 Distributeurs & Manufacturiers de l'est cie ltée.3310 Distributeurs de produits industriels de Sept-Iles ltée (Les).3310 Ducharme (J.A.) & Fils limitée.3310 Duvernay Equipement limitée.3310 Emmaus-Granby.3310 Engora Enterprises Ltd.3310 Entreprises Crystal Clair de Laval inc.(Les).3310 Fédération québécoise de la compétition- motoneige.3310 Foisy (Stanley) limitée.3310 Freecan Industries Inc.3310 Gestion S.A.P.inc.3310 Giroux (Emile) limitée.3311 Glass (Mel) & Léon Pascal Importers Limited 3311 Guay (Adélard) inc.3311 Guilinc.3311 Hodge & Lloyd Limited.3311 Horizon Holdings Inc.3311 Houde Larouche & Cie ltée.3311 3406 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1971,, Vol.106, No.18 Lettres \u2022patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Hut Barbecue Inc.(The).3311 Hyco Fur Company Incorporated.3311 Iannuzzi (D.A.) & Sons Inc.3311 Ideal Textiles Inc.3311 Ideal Trading Corporation.3311 Be Perrot Yacht Club Inc.(The).3311 Imperial Auto Sales Corporation.3311 Imprimerie Pigeon limitée.3311 Indépendant Merchants Association of Québec (The).3311 Industries Agricola inc.3311 Industries Laurentiennes limitée (Les).3311 Industries Patapédia limitée (Les).3311 Institut canadien des affaires publiques (ICAP)(L').3311 Inter-British Trading Co.Inc.3311 Interknit Limited.3311 International Asbestos Company Ltd.3311 Jacoby Studios Incorporated.3311 Attala (Jacques et Paul) inc.3311 Jagra Import and Underwear Company Limited.3311 Jardiniers unis de Québec.3311 Jayceear Realty Corporation.3311 Jeannotte (Bruno) limitée.3311 Jerri Inc.3311 Jeune Commerce de Gaspé inc.(I*).3311 Jeunesse-Ville inc.3311 Jewellers Plating Ltd.3311 Jewish Citizen's League of Montreal Inc.3311 Jewish School Publishing Association Inc.3311 Jo Ann Lingerie Corporation.3311 Joe's Sandwich Shop Inc.3311 Johnson Fruit Company Limited.3312 Joliette Foundry & Tool Works Limited.3312 Joliette Machine Works Limited.3312 Joliette Textile Corporation.3312 Joliette Worsted Co.Ltd.3312 Jonquière Quilles limitée.3312 Josef Inc.3312 Joseph (H.) & Co.inc.3312 JoyelCorp.,.3312 Jubilee Médecines Co.3312 Juddmar Inc.3312 Julien électrique Company limitée.3312 Julien (J.C.) limitée.3312 Kaiser (CH.) & Son Inc.3312 Kanbec Gold Mines Limited.3312 Kane Products Inc.3312 Kapp Agencies Ltd.3312 Kastner limitée.3312 Kenmar Textiles Limited.3312 Kent Trading Corporation.3312 Kertchiff Dress Inc.3312 Keystone Overall & Pants Mfg.Co.Inc.3312 Knight of the Round Table Alumni Association Inc.3312 Kotler (B.) Inc.3312 Laboratoire Cunard limitée.3312 Labrador Construction Company Limited.3312 Lac StJean automobile limitée.3312 Ladouceur Auto Repairs Limited.3112 Laflamme & Laflamme Limited.3312 Lafond & Coderre ltée.3312 Lafontaine ltée.3312 Lahaio automobile ltée.3312 Lahaye inc.3312 Laing's Inn Inc.3312 Laiterie La Suète limitée (La).3312 Laiterie moderne de St-Eustache limitée.3312 Laiterie Pinard limitée.3312 Laiterie St-Jean-Baptiste limitée (La).3313 Lajoie Grocers Incorporated.3313 Lakeland Sportswear Incorporated.3313 Lakeshore Football Club Inc.(The).3313 Lamy & Fils limitée.3313 Landa Frocks Inc.3313 Landry (A.C.) limitée.3313 Landry & McNeil Inc.3313 Landry & Perry limitée.3313 Langelier (J.Robert) Shoe Manufacturing Co.Ltd.3313 Langlois Motor Sales Limited.3313 Lanoix (Bernard) limitée.3313 Lanquetot & Fils limitée (M.).3313 Lessard Police Equipment & Sports Inc.3313 Ligue de crosse des cantons de l'Est.3313 I,ortie & Roussin incorporée.3313 Lumber & Supply Inc.3313 Lustralite Corporation.3313 Lynns Ladies Wear Inc.3313 M.A.Knitting Mills Limited.3313 M.& A.Sheet Metal Works Ltd.3313 M.& J.Noveltv Co.Ltd.3313 M.& R.Traders Inc.3313 Mab limitée (Limited).3313 Macamic Inc.3313 MacDonald Smelting & Refining Company Limited.3313 MacLeod (D.E.) Granite Inc.3313 Macy Fur Co.(The).3313 Mademoiselle Modes inc.3313 Madison Dress Inc.3313 Mafco Corporation Ltd.3313 Magasin Belle-Rivière limitée.3313 Magasin Gareau limitée.3313 Magma Mines Limited.3313 Maher (Jas.H.) & Son Ltd.3313 Main Motor Sales Inc.3313 Main Street Club of Montreal Inc.(The).3313 Maison Bourdon inc.3314 Maison Chambord ltée.3314 Maison Charmaine ltée.3314 Maison colombienne de Roberval incorporée (La).3314 Maison Diana inc.(La).3314 Maison Joseph Boumansour limitée (La).3314 Maison Notre-Dame de l'Enfance.3314 Maître Voilier inc.(Le).3314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 1974, 106' année, n° 18 3407 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) {continued) Maîtrise d'arts limitée.3314 Majestic Industries Limited.3314 Malartic Club.3314 Manhattan Company Limited.3314 Manoir Investments Limited.3314 Manoir Rocher Panet inc.3314 Mansfield Realty Corporation Limited.3314 Mansions Motors Limited.3314 Mansonville Utilities Limited.3314 Manufacture de meubles Matane ltée.3314 Manufacture de robes et costumes de Repenti- gny inc.3314 Maple Leaf Cleaners & Dyers Co.3314 Maple Leaf Peat Limited.3314 Maple Leaf Textiles Ltd.3314 Maple Leaf Transport Limited.3314 Maple Orchards Limited.3314 Mapron Realty Inc.3314 Marathon Construction Company Limited.3314 Marbo Plastics Co.Ltd.3314, Marcelle's Ladies Wear Inc.3314 Marchand & Hamel automobile ltée.3314 Marché de fruits Jacques-Cartier ltée.3314 Marché St-Vallier limitée.3314 Marché-Davis-Market limitée.3314 Marcotte (A.E.) ltée.3314 Margie Don Incorporated.3314 Margolis (Samuel) Dress Corp.3314 Margot Coats Inc.3314 Mariette Gold Mines Limited.3314 Maritime & Gulf Lumber Limited.3315 Maritzer Dress Inc.3315 Marley Agencies Limited.3315 Marshall Ross & Co.Ltd.3315 Marsoul Mines Limited.3315 Martel garage cie ltée.3315 Martin limitée.3315 Mary's Food Market Inc.3315 Maskoutaine limitée (La).3315 Massicotte (L.) ltée.3315 Master Footwear Incorporated.3315 Master Ladies-Hairdressers and Wigmakers Guild (The).3315 Matane Beach County Club incorporé.3315 Matane Works Inc.3315 Maxwell Holdings Inc.3315 Maxwell Spreads Inc.3315 May (Deanna) Inc.3315 Maybery Hat Incorporated.3315 Mayfair Food Corporation.3315 Mayou-Pencer Clothes Inc.3315 McCulloch Equipment Co.Ltd.3315 McGill Fur Limited.3315 McGill Printing Limited.3315 McHarg & Wade Ltd.3315 McLean (D.V.) Incorporated.3315 Medical Acoustic Instruments Limited.3315 Megantic Aero Service Limited.3315 Megantic Mills Ltd.3315 Meilleur (Georges) & Fils inc.3315 Mel-Ber Manufacturing Company.3315 Memphremagog Water Power Association Incorporated.3315 Mendelsohn (S.) Inc.3315 Men's Apparel Inc.3315 Menuiserie canadienne limitée (La).3315 Merchants Clothing Co.Ltd.3315 Mercury Shoe Co.Ltd.3315 Merry Maid Fashions Inc.3315 Metal Heat Treating Co.3316 Metal Industries Incorporated.3315 Metallic Crystal Gauge Co.Ltd.3316 Metalore Mining Corp.Limited.3316 Métayer, Simoneau et Panneton limitée.3316 Metro Textiles Ltd.3316 Métropole Club Incorporated.3316 Métropole construction ltée.3316 Metropolitan Braids Ltd.3316 Metropolitan Goulet Company Limited.3316 Metropolitan Jewellery Mfg.Co.Ltd.3316 Metropolitan Manufacturing & Supply Co.Ltd.3316 Metropolitan Service Incorporated.3316 Metwood Products Inc.3316 Meubeau Inc.3316 Meuble Somerset limitée (Le).3316 Miami lingerie inc.3316 Michael Manufacturing Company Limited.3316 Mictaw Mines Limited.3316 Midland Industries Ltd.3316 Mid-Town Dress Inc.3316 Miklos Incorporated.3316 Milady Hat Mfg.Co.Ltd.3316 Mile End Fruit Exchange Incorporated.3316 Milicent's Incorporated.3316 Milk For Health Incorporated.3316 Miller (A.I.) & Sons Ltd.3316 Miller (D.A.) Co.Ltd.(The).3316 Miller Trading & Manufacturing Ltd.3316 Miller's Economy Store Limited.3316 Milmar Cleaners & Dyers Inc.3316 Mil-War Ltd.3316 Mimeo-Stencil Manufacturers Limited.3316 Mines Holdings Limited.3316 Mines d'or Bellehumeur ltée (Les).3316 Minesco Inc.3316 Mineshafts Limited.3316 Mireille incorporée.3317 Miss America Maid Incorporated.3317 Mistassini Lead Corporation Limited.3317 Modern Age Manufacturing Company Limited.3317 Modern Frocks Limited.3317 Modern Home Furnishers Ltd.3117 Modern Novelties & Specialties Limited.3317 Modern Spinners Inc.3317 Modern Traders Ltd.3317 Modern Wood Products Ltd.3317 Modernaire Incorporated.3317 Modernité Industries Limited.3317 3-10S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Modes du jour limitée.3317 Moliver Sisterhood and Brotherhood Society (The).3317 Molyca Mines Limited.3317 Monarch Realty & Administration Company.3317 Monette Furs Inc.3317 Montcalm Lumber Company Inc.(The).3317 Montex Limited.s.3317 Montfort Country Club Inc.(The).3317 Mont-Louis Mines Limited.3317 Montreal Blanket Company (The).3317 Montreal Blouse & Sports Wear Inc.3317 Montreal Civic Centre Incorporated.3317 Montreal Clothing Co.Inc.3317 Montreal Dental Supply and Manufacturing Company Limited (The).3317 Montreal Die Casting Co.Ltd.3317 Montreal Elgar Choir (The).3317 Montreal Figure Skating Club Incorporated (The).3317 Montreal Football Club Incorporated.3317 Montreal Fruit Receivers Association Inc.3317 Montreal Fuel Cell Form Supplyers Ltd.3317 Montreal Harwood Flooring Co.Ltd.3317 Montreal Hat & Cap Manufacturers Association Inc.3317 Montreal Hearing Aids Bureau Inc.3317 Montreal Hebrew Old Peoples' and Sheltering Home (The).3317 Montreal Horse Show Ltd.(The).3318 Montreal Industries & Enterprises Limited.3318 Montreal Iron and Metal Smelters Limited.3318 Montreal Island Power Company.3318 Montreal Kennel Association Inc.3318 Montreal Knitting Mills Inc.3318 Montreal Merchants' Association.3318 Montreal Model Railroad Club Inc.3318 Montreal Orchestra Inc.3318 Montreal Plaster Works Incorporated.3318 Montreal & Provincial Shoe Repairers Association Inc.3318 Montreal Quarry Limited.3318 Montreal Veneer Panel Inc.3318 Montreal Wartime Fuel Committee Inc.3318 Montreal Wax Paper Manufacturing Company Limited.3318 Montreal-New York Express Ltd.3318 Montreal-Ottawa Express Line Limited.3318 Mor-Ann Fashions Inc.3318 Mordave Realty Inc.3318 Mordipal Construction Company Inc.3318 Morency Motor Sales Ltd.3318 Morin (J.B.) & cie limitée.3318 Morin (J.B.) inc.3318 Morin Lumber Limited.3318 Mor-Lite Realty Corporation.3318 Morton Clothes Ltd.3318 Mount Royal Mines Limited.3318 Mountain Castle Inc.(The).Mountain Crest Mines Limited.Mountain Limited.Mountain View Bungalows Limited.Multi-Products Limited.Mundy Grain Trimmers Patents Limited Murray Cold Storage & Warehousing Co.Ltd.Mutual Enterprises Ltd.Mutual Industries Limited.Mutual Sportswear Incorporated.Myron Glass Frame Inc.Natalie inc.National Accessories Company Limited.National Construction Co.Limited.National Frames Limited.National Fruit Exchange Incorporated.National Hardware Inc.National Health Association.National Realty & Building Company.National Shoe Repairers Protective Association Incorporated.Needleworks Limited (The).Nelson Plumbing & Heating Company Limited.Nemo Construction Co.Ltd.Neo-Bcauty Line Company Limited.Nets Incorporated.New Chiriotto Farm Inc.(The).New Palace Hotel Limited.Newa-Ad Incorporated.Panorama Distribution Inc.Pelon Inc.Perald Inc.Planchers Dominion inc.Prahova Mines Limited.Princeville Woodcraft Limited.Prominent Garment Inc.Provincial Laboratories Limited.Pyramid Metals Incorporated.Québec Explorers Ltd.Québec Motor Sales Company Limited.Québec Musical Competition Festival Incorporated (The).Québec Precambrian Corporation Limited.Québec Rokorol Limited.Québec Textiles Inc.R.& G.Machine Rebuilders Ltd.Radio Groupe Trans Québec Inc.Ranchousc Foods Ltd.Rangers Club Inc.Ratello Social Club Limited.Red Comet of Canada Ltd.Réfrigération « Glaciale » limitée.Renardière P.A.Alain limitée (La).Renaud and Sons Ltd.Renco Limited.Revanna Sportswear Inc.Rhodt Metal Works Ltd.Rimoin's 5i to SI .00 Stores Inc.Roy (Marcel) & Associés inc.St-Lawrence Hardware Inc.3318 3318 3318 3318 3318 3318 3318 3318 3318 3318 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i mai 197i, 106- année, n° 18 3409 Lettrée patentes annulées: Letters Patent Annulled: (.suite) (continued) Sanatorium Bruchési de Montréal (Le).3320 Sanatorium de Gaspé inc.(Le).3320 Sanders Garment Inc.3320 Savannah Confectionery Limited.3320 Scott Jewellery Co.Ltd.3320 Seaforth Alines Limited.3320 Seagreen Laboratoires inc.3320 Seaward Limited.3320 Secrétariat des syndicats catholiques de Montréal incorporée.3320 Séguin Consolidated Mines Limited.3320 Seligman (Jack) Incorporated.3320 Selinger (H.) & Sons Ltd.3320 Sénat de la Jeunesse (Le).3320 Sendel (Louis A.) Co.3320 Sendel Machinery Corporation.3320 Serrure de capot Général inc.3320 Service d'améliorations limitée.332b Service d'aviation Charlevoix Saguenay ltée.3320 Service de lavage de 10 minutes ltée.3320 Service des loisirs de Ste-Scholastique.3320 Service Pleating Incorporated.3320 Service populaire inc.3320 Service Sportswear Mfg.Co.3320 Service Tooling Co.Ltd.3320 Services publicitaires incorporés.3321 Seven Eighteen Corporation.3321 Seven Islands Lions Club Inc.3321 Shachter (Jack) Incorporated.3321 Shakespeare Club.3321 Shawinigan Mica Limited.3321 Shawinigan Plywood Products Limited.3321 Shawmaque Gold Mines Ltd.3321 Shayne (A.) Inc.3321 Sheffield Steel Blade Ltd.3321 Shefler (H.C.) Inc.3321 Sherbrooke Feeds Limited.3321 Shermont Inc.3321 Shoecraft Company Limited.3321 Shulman Cap Company Limited.3321 Sidney Textile Corporation.3321 Sigma Phi Delta Fraternity Montreal Inc.3321 Sil-Blu Garment Inc.3321 Silmont Import Inc.3321 - Silver Granite Company Limited.3321 Sim-Artlnc.3321 Simis Inc.(Service d'information de Montréal.3321 Simis Realties Inc.\u2022.3321 Simmons Mining Company Limited.3321 Simon (J.) & Company Limited.3321 Simon Shoe Company Limited (The).3321 Simoneau (J.P.) ltée.3321 Singer Jackson Fashions Inc.3321 Sinotte (Donat) inc.3321 Skalllnc.3321 Skoda & Son Limited.3321 Sky Cruises Incorporated.3321 Skyline Clothes Inc.3321 Slater Bros Inc.3321 Small General 5é Store Ltd.3321 Smart Children's Wear Incorporated.3321 Smart Made Dress Company Ltd.3321 Smart Miss Inc.3322 Smartwear Limited.3322 Smeaton Bros.Limited.3322 Smiling Juniors Inc.3322 Smith (Arthur) Furs Inc.3322 Smith Building Services Ltd.3322 Smith (J.) ltée.3322 Smith (W.W.) & Company Limited.3322 Smith's Sanitary Supply Co.Ltd.3322 Snowdon Dry Cleaners Inc.3322 Société canadienne d'assistance médicale incorporée.3322 Société classique (La).3322 Société d'entraide Québec Haïti.3322 Société générale de Sainte-Luce-sur-Mer limitée (La)._.3322 Société d'histoire régionale de Lachine.3322 Société immobilière Maisonneuve limitée.3322 Société de placements St-Georges ltée (La).3322 Société des produits Délecta limitée.3322 Société St-Jean-Baptiste de Sayabec (La).3322 Société des secouristes de Québec inc.(La).332* Society Hat Mfg.Co.Ltd.3322 Soieries Boell limitée.3322 Somerled Realties Company Ltd.3322 Sourisse (Victor C.) & compagnie incorporée.3322 South Shore Echo Ltd.3322 Southern Slippers (1966) Ltd.3322 Spécialités LaSalle Specialties Inc.3322 Sport Guild Inc.3322 Standard Steel Products Limited.3322 Stanley Club Inc.(The).3322 Stanray Company Limited.3322 Stella Dress Inc.3322 Sterling Embroidery Ltd.3322 Sterling Fur Company.3322 Sterling Slipper Inc.3322 Structures universelles inc.3322 Stuart Enterprises Ltd.3322 Studio Albert Dumas limitée.3322 Studio Hébert ltée.3323 Style Signs Ltd.3323 Trans-Kébec Vacuum (Que.) Inc.3323 Tremblay Lumber Co.Ltd.3323 Trumor Securities Ltd.3323 Vanguard System Inc.3323 Vera Pizza Inc.3323 W.B.Realty Company .3323 Youth Employment Service Corporation.3323 Révocation de dissolution: Revocation of Dissolution: Académie de musique de Ville de Laval.3323 Arwepiwin Fish & Game Club.3323 Association Age d'Or Saint-Odilon (L').3323 Château Inn limitée.3323 Club Doc inc.3323 Club du Tableau.3323 3410 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 4, 1974, Vol.106, No.18 Révocation de dissolution: Revocation of Dissolution: (suite) (continued) Club Etoile Filante inc.f.3323 Club Le Paradis de l'Orignal.3323 Club Millechanne inc.3323 Club Optimiste de St-Hyacinthe inc.(Le)- 3323 Concept 2887139 ltée.3323 Concept 2887139 Ltd.3323 Corporation du tourisme de Rivière-du-Loup (La).3323 Fédération des Sociétés d'histoire du Québec.3323 Vida (Peter) Inc.3323 Walsh (Joseph) Ltd.3323 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Chauveau, c.s.r.-r.s.b.(Correction).3389 Drummondville, cité-city.3387 Du Cuivre, c.s.r.-r.s.b.(Correction).3389 Montcalm, c.s.-s.b.(Correction).3389 Repentigny, ville-town (Correction).3389 St-Agapitville, village (Correction).3389 Saint-Emile, village.3384 Sillery, cité-city.3386 SYNDICATS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL SYNDICATES Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'est du Québec (STEEQ) (Siège-social-Head office).3380 Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'est du Québec (STEEQ) (Nom-Nome ch.).3380 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Goods CP Express Limited.3390 Cie de Messageries CP Limitée (La).3390 Par Shérifs By Sheriffs Montréal Montreal BP Pétroles limitée vs Admirai Construction Co.Ltd.3393 Caisse Populaire St-Vincent Ferrier vs Cam- bourieu.3394 Canada Permanent Trust Company vs Druker 3393 Marten et Recalde vs Beament.3395 Nelsson vs Héritiers-Heirs Nikolaus Szumylo.3394 Québec Québec Caisse populaire de Sillery vs Proulx.3398 General Trust of Canada vs Taverne Coloniale Inc.et al.3397 Marchand vs Bel lavance.3396 Paquet vs Filteau Lagacé.3398 Polinia vs Les immeubles Bovar inc.et al.3395 Trust Général du Canada vs Taverne Coloniale Inc.et al.3397 Trois-Rivières Trois-Rivières Huppé vs Tourigny.3398 SOMMAIRE SUMMARY Avis divers.3375 Applications to Legislature.3368 Changement de nom, Loi du: Change of Name Act: Accordés.3378 Applications.3374 Demandes.3374 Granted.3378 Commission des transports du Québec.3332 Compagnies, Loi des: Abandon de charte.3328 Changement de nom.3330 Demande d'abandon de charte.3380 Lettres patentes (/\" partie).3324 Lettres patentes (S' partie).3329 Lettres patentes supplémentaires.3331 Compagnies étrangères: Permis.3390 Demandes à la Législature.3368 Ministère: Affaires municipales.3391 Proclamations.3381 Régie de l'Électricité et du gaz.3392 Renseignements sur les compagnies: Avis de dissolution éventuelle de corporations.3301 Erratum.3324 Lettres patentes annulées.3308 Révocation de dissolution.3323 Soumissions.3384 Companies Act: Application for surrender of charter.3380 Change of name.3330 Letters patent (Part I).3324 Letters patent (Part III).3329 Letters patent supplementary.3331 Surrender of charter.3328 Companies Information Act: Erratum.3324 Letters Patent Annulled.3308 Notice of Eventual Dissolution of corporations 3301 Revocation of dissolution.3323 Department: Municipal Affairs.3391 Electricity and Gaz Board.3392 Extra-Provincial Companies Act: Licenses.3390 Miscellaneous Notices.3375 Proclamations.3381 Professional Syndicates Act.3380 l Québec Transport Commission.3332 3393 3395 3398 3390 3384 Syndicats professionnels, Loi des.Ventes: Effets non réclamés.3380 3390 Par shérifs: Montréal.3393 Québec.3395 Sales: By Sheriffs: Montreal.Québec.Three Rivers.Unclaimed Goods.Trois-Rivières.3398 Tfnders. nouveautés CAHIERS Ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre 2.4.3.\u20141780 Code de l'électricité Québec, 1974.575 p.format de poche S 3.00 2.4.3\u20141781 Code de l'électricité / Electrical Code Québec.1974.550 p.S 5.00 Ministère de l'Éducation Office de la langue française BULLETINS 3.1.1\u20141754 Canadianismes de bon aloi par Maurice Beaulieu, Gaston Dulong en collaboration Québec, 1973.11 p.$ 0.50 3.1.1.\u20141755 Vocabulaire des assurances sur la vie par Jean-Paul de Grandpré Québec, 1973.16 p.$ 0.50 3.1.1.\u20141756 Vocabulaire des élections par Céline Dupré.Denise Perron en collaboration Québec, 1973.42 p.$ 1.00 3.1.1\u20141757 Vocabulaire de la radio et de la télévision par France Québec, 1\t,73.1^U LE\t$ 0.50 3.1.1\u201417! Lexique d\tL 9 aMWH la prévention des accidents-| BIBLIOTHEQUE NATIONALE\t par Marie-B/a de Villejg-SidjÉtëEC Québec.1973.137 p., ill.S 2.00 3.1.1\u20141759 N°3 3.1.1\u20141760 N° 8 3.1.1.\u20141761 N° 14 3.1.1\u20141762 N° 17 3.1.1\u20141763 N° 18 3.1.1\u20141764 N° 19 Vocabulaire bilingue des assurances sur la vie par Jean-Paul de Grandpré Québec.1969.39 p.$ 1.00 Lexique anglais-français des produits de la pèche.Fascicule 1 : Poissons, crustacés et mollusques par Thérèse Villa en collaboration Québec, 1971.36 p.S 1.00 Lexique anglais-français de la banque et de la monnaie.par Pierre Ricour en collaboration Québec.1973.87 p.$ 1.50 Lexique anglais-français de la bourse et du commerce des valeurs mobilières.par Jean Capron en collaboration Québec.1973.76 p.S 1.50 Lexique anglais-français de l'industrie minière Fascicule 1 : L'exploitation par Pierre Auger et Louis-Jean Rousseau Québec.1973.91 p.$ 1.50 Vocabulaire français-anglais de la machine à coudre industrielle par François Lanecki, sous la direction de Céline Dupré Québec, 1973.85 p.S 1.50 JL L'ÉDITEUR OFFICIEL i DU QUÉBEC 675, EST BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.