Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 18 (no 20)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-05-18, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" 18 MAI 1974 N° 20 on 3569 AUE8 03/ PTIE 1 EX.2 GAZETTE OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE PARTE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES M-al GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO_3571 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Quebec.CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publiehcr PARTIE 1 TS PART 1 3572 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1) : du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRD7TION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Quebec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GlA 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GlA 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106- année, n° SO 3573 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 6a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ALASKA FURS & SKINS LTD.25788 ALBERT IMPORT CO.77035 ALOUETTE SEWING CENTRE INCORPORATED.26610 ALTA INVESTMENT CO.LIMITED.5899 AMEUBLEMENT ROBERT LTEE.235840 L'AMICALE DOLLARD.29037 ASSOCIATION ATHLETIQUE ST-LAWRENCE.127883 ASSOCIATION OF THE ITALO-CANADIAN WORKERS INC.L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHARLESBOURG OUEST.29036 L'ASSOCIATION DU TERRAIN DE JEUX DES ARTISANS DE LA BAIE ST-PAUL 29126 ASTOR AGENCIES LTD.27329 LES ATELIERS DE SOUDURE DE RIMOUSKI LIMITEE .4340 AUBERGE DE L'ETANG INC.72058 AUDIO COMMUNICATIONS LIMITED.26060 AUTOMOTIVE GENERAL SUPPLIES LTD.4385 B.C.CONSTRUCTION INC.4442 BABY'S DIAPER SERVICE LIMITED.*.4468 Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1972et/andl973 Montréal.1967 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine- 1954 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1971,1973 Montreal.1955, 1956, 1959 à/to 1973 incl.Charlesbourg-Ouest .1954 à/to 1973 incl.Baie-St-Paul.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Rimouski.1973 Cap Santé.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1963 incl., 1965, 1971 à/to 1973 incl.L'Abord-à-Ploufie.1946,1970 à/to 1973 incl. 3574_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 7974, Vol.106, No.S0_ Nom de la compagnie Name of the company BAKER HOTELS LIMITED.4497 BALDWIN'S STORAGE LTD.4608 BAMBINO SECURITY LTD.72069 BAUER INTERNATIONAL INVESTMENT A SECURITIES CO.LTD.79095 MARCEL BELANGER CIE LTEE.32692 ROBERT ET GERARD BENOIT INC.104054 C.BERTRAND INC.86432 BOULEVARD RESTAURANT INC.30708 J.BOURBEAU DUFRESNE LIMITEE.29196 BOUTIQUE DE MONSIEUR PIERRE INC.77052 BREUVAGES JANO INC.93039 BROADWAY TEXTILE PROCESSING LTD.77067 DINAH LILY CAPLAN SOCIAL SERVICE GROUP.LA CARRIERE DESCHAMBAULT INC.8018 LES CARRIERES MARTINEAU ET DESCHAMBAULT INC .6363 CHENOY BOYS DELICATESSEN LTD.30709 LA CIE JARRY-FABRE LTEE.27366 CLUB DE C.* P.S.L.C.POINTE JAUNE.126863 LE CLUB DE CROQUET LE TROIS-RIVIERE8 INC.29034 CLUB DICO.236406 LE CLUB PAPINEAU INCORPORE.691 LE CLUB DES PROFESSIONNELS DU QUEBEC INC.32687 CLUB RICHELIEU STE-ROSE DE LAVAL INC.71228 LE CLUB DES SPORTIFS D'ALMA INC.t.43418 Adresse Rapporta non produits Addreea Return* not filed Gaapé.'973 Sherbrooke.1968, 1972 et / and 1973 McMaatervilie.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1957 à/to 1973 incl.Chàteauguay.1968, 1972.1973 Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1954 à/to 1973 incl.Troia-Rivières.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Lea Saules.1969.1970.1972 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.1973 Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1963 à/to 1973 incl.Gaapé.1963 à/to 1973 incl.Troia-RIvicres.1967, 1959, 1961 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1961.1969 à/to 1973 incl.St-Gérard-Magella.1969 à/to 1973 incl.Ste-Rose.1966, 1966.1968 à/to 1973 incl.Aima.1969.1960.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3575 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LES CLUBS JUVENILES DE LA CITE JACQUES-CARTIER INC.27369 COLONIAL CHROME COMPANY LIMITED.858 COMITE D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER DE ST-ZENON 29040 LA COMPAGNIE D'IMMEUBLES DE MONTREAL.153725 COMPAGNIE DE PLACEMENTS DES MILLES ISLES LIMITEE 6417 LA COMPAGNIE DE PUBLICATION .L'ECONOMIE RURALE .INC.27366 CONSEIL D'HABITATION ECONOMIQUE BEAUFORT LTEE 120898 CONSOLIDATED DOLSAN MINES LTD (NO PERSONAL LIABILITY) 8489 CONTINUOUS FORMS (QUEBEC) LIMITED.71495 CORPORATION DES CHEMINS D'HIVER D'ABITIBI-OUEST 24356 Jacques-Cartier.1963 à/to 1973 incl.D.C.COUVERTURES INC.234894 D.F.N.WOOD PRODUCTS LIMITED.7702 D.P.LUMBER CORPORATION.7708 DAISY DEVELOPMENT CORP.60008 DALAC MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).7739 DALBROSS CONSTRUCTION LIMITEE.7742 D'AMOUR INC.7765 DAUPHIN INC.7817 DAVE'S MARKET INC.7822 DE LA SALLE CHESTERFIELD INC.7925 DECARIE BOULEVARD LAND DEVELOPMENT CO.LTD .7882 HY DECKELBAUM LTD.7893 DEL MONTE STUDIO INC.7943 Black Lake.St-Zenon.Montréal.Montréal.1964.1973 1954, 1956 à/to 1973 incl.1932 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 Montréal.1963 à/to 1973 incl.Ste-Catherine-d'Alexandrie.Montreal.Montreal.LaSarre Gatineau.Sherbrooke.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.1971 à/to 1973 incl.1968, 1973 1963 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1947 à/to 1973 incl.1948 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1946 à/to 1973 incl.1950 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1948 à/to 1973 incl.1950 à/to 1973 incl.1945 à/to 1973 incl.1946 à/to 1973 incl.1961, 1966.1972, 1973 1950 à/to 1973 incl. 3576 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company DELSON LUMBER INCORPORATED.30853 DEMERS & CIE INC.7965 D.DENOMMEE & COMPANY LIMITED.7993 T.N.DENYS 4 CIE LIMITEE.7996 LEANORA DERICE INC.27358 DERMER MFG INC.8009 DESCHAMPS & BELANGER LTEE.8019 DESFOSSES & FRERES LTEE.8031 DESMARAIS A PELLETIER INC.76794 DEUX-MONTAGNES DRIVE YOURSELF INC.30854 DEVON SOCIETY, INC.8084 DIANA RESTAURANT INC.8115 DIANA SHOE COMPANY LIMITED.8116 DICKMAN & DICKMAN INC.8120 A.DION & FILS INC.76797 DISTRIBUTEURS PLATEAU LTEE.72219 DISTRIBUTORS INCORPORATED.8163 DOCTOR X PREPARATIONS LTD.8178 DOMAINE DES PINS LTEE.8195 DOMESTIC HEATING INCORPORATION.8202 DOMINION CONCERTS INC.8228 DOMINION DRESS LIMITED.8236 DOMINION ELECTRIC CONTRACTORS CO.8238 DRAPERIES QUEBEC INC.26293 MAURICE DUBUC LTEE.30227 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Delson Village.1956 à/to 1973 incl.Victoriaville.1950 à/to 1973 incl.St-Damien-de-Brandon .1949 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1972, 1973 Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.St-Eustache.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Québec.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971, 1973 Montreal.1946 à/to 1973 incl.Oka.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1947 4/^ 1973 Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1973 incl.Q\"41*0.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3577 Nom de la compagnie Name of the company EASTERN TELEVISION IMPORT CO LTD.25793 L'ECLAIR ELECTRIQUE LTEE.32669 ECOLE PROVINCIALE DES MAITRES NAGEURS INC.112069 EXCEL GARMENT INC.32571 FOREIGN TRADES BUREAU INCORPORATED.2427 G.A.ALUMINIUM INC.100944 GARAGE BELLEY LIMITEE.26926 GASPE SERVICE STATION LTD.27170 GAZ MEDICAL P.A.LTEE.235288 GEM MOTOR SALES LIMITED.27306 A.GENEST LTEE.1164827 GE3TION MODULAIRE INC.118808 HAYCOCK REALTIES INC.3133 HOTELLERIES FAUCHER INC.26817 HURON FISHING TACKLE INC.6025 HYGRADE FUR CO.76832 LES IMMEUBLES POULIN REALTIES LTD.32590 IMPRIMERIE CREMAZIE LTEE.6220 INDEPENDENT REFRIGERATION LIMITED.5247 INDOOR GAMES LIMITED.5265 INDUSTRIAL APPLIANCES CORPORATION.5268 INDUSTRIAL APPLIANCES LTD.5269 INSTITUTE OF RADIO AND TELEVISION.23991 ITALO CANADIAN CLUB OF ROUYN NORANDA INC.31117 J.B.SKI CLUB INC.9000 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Farnham.1963 à/to 1973 incl.Sepfr-Iles.1955 à/to 1973 incl.Laval.1969 à/to 1973 incl.Ste-Rose.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Matane.1968, 1972, 1973 Jonquière.1953 à/to 1973 incl.Gaspé.1953, 1955 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1953 à/to 1973 incl.Roberval.1967.1971 Ste-Foy.1972,1973 Montreal.1967.1969 à/to 1973 incl New Carlisle.1953, 1955, 1961 à/to 1973 incl.Québec.1970, 1973.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1945 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1952 à/to 1973 incl.Rouyn.1973 Mt Tremblant.1972,1973 3578 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol 106, No.SO__ Adresse Rapporta non produits Address Returns not filed Jonquière.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1960,1971 à /to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Lachine.1973 Montreal.1973 Montreal.1961, 1963 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Outremont.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1973 St-Jean.1972, 1973 Montreal.1966, 1967, 1968, 1973 Longueuil.1966.1967, 1968, 1973 Montréal.1960 à/to 1964 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Lachine.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.St-Jude.1963 à/to 1973 incl.Québec.1967.1966, 1966, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.iQfie à/to 1973 incl.Nom de la compagnie Name of the company JARDIN ROYAL LTEE.113836 JEDO BELTS LTD.32682 JOLIETTE PANTS A SPORTSWEAR LTD.9189 JOY FROCKS INC.9231 JULMOR LTD.64923 KAEMES CONSTRUCTION CO.LTD.29091 KILL-ODOR PRODUCTS INC.24368 THE KINSMEN CLUB OF LACHINE-DORVAL INC.9465 KIRK TRADING CORPORATION.9459 KIRKOR INVESTMENT CORP.49823 KLEINERT COMPANY LIMITED.9487 LAD AND LASSIE NURSERY AND KINDERGARTEN INC.88662 NAP.LAFOREST A FILS LIMITEE.9735 LA LAITERIE GRANGER FRERES, LTEE.9770 LAITERIE MILE END LIMITEE.9781 LAITERIES ROUEN INC.9794 W.LAJEUNESSE A CIE LIMITEE.9802 LAKESHORE INDUSTRIES INC.26702 LEANDRE LAMONTAGNE LIMITEE.9887 LAMONT'S MEN'S WEAR LIMITED.72348 LASALLE FINANCE CORPORATION LTD.27310 STEVE LAWRENCE INC.8861 LECLAIR FROZEN EGG PRODUCTS INC.72349 RUDY LESSARD INC.9662 LIGUE ANTI-POLLUTION LEAGUE INC.30817 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3579 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed LA LIGUE DES CITOYENS DE ST-MARC-DES-CARRIERES INC.97927 LA LIGUE DES CITOYENS DE SAINT-THOMAS D'AQUIN DE STE-FOY INC.29198 LA LIGUE DE HOCKEY JUNIOR i B ¦ DE LA CITE DE RIVIERE-DU-LOUP 29039 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE ST-SIMON-DE- DRUMMOND 27357 SainWMarc-des-Carrières 1967, 1969, 1971 à/to 1973 incl.LOGEMENT DE HULL LIMITEE 30819 LOISIRS D'ARTHABASKA INC.81602 LOUANDA REALTIES INC.235346 LOUANDA REALTIES INC.236345 LUCKY STAR REALTIES INC.73208 MAJESTIC ENTERPRISES INC.40133 MANDARIN GARDENS INC.10384 LA MANUFACTURE DE MANCHES BOISVERT A CIE LTEE 10432 P.MARCHAND LIMITEE.10496 MARINA COLD STORAGE CO.LTD.10556 LES MARQUIS JUNIOR B INC.29089 MARTIN REALTIES INC.10639 MAW BROTHERS LIMITED.153726 MEGANTIC AUTO INC.10806 MERCHANTS HOUSING COMPANY LTD.24253 MERGL ET FILS COMPAGNIE LIMITEE.32673 METALLICS A PLASTICS LIMITED 10908 METALLURG (CANADA) LTD.7564 METROPOLE MOULDING CO.LTD.10937 Ste-Foy.Rivière-du-Loup.StrSimon-de-Drummond.MEUBLES ANTOINE INC.65932 Hull.Arthabaska.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Grand ea-Pil es.Québec.Montreal.Jonquière.Montreal.Montreal.Lac Mégantic.Montreal.St-Martin.Montreal.Montreal.Montreal.Gatineau.1954 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1953 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1973 1932 à/to 1947 incl.,1973 1961, 1965, 1967, 1970 à/to 1973 incl.1954 à/to 1973 incl.1973 1932 à/to 1973 incl.1961, 1972, 1973 1954 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1960, 1972,1973 1971 à/to 1973 incl.1973 1963, 1964, 1966, 1970 à/to 1973 incl. 3580 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 197A, Vol.106, No.30___ Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1968 à/to 1973 incl.Barkmere.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.St-Laurent.1966 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Pointe-GatinBau.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.St-Michel.1963 à/to 1973 incl.Québec.1958, 1960 à/to 1973 incl.Ste-Marguerite 1968 à/to 1973 incl.(Dorchester) Port-Alfred.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1970 incl.1972.1973 Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1960, 1965 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Québec.1957 à/to 1963 incl.1966 à/to 1973 incl.Port-Cartier.1963 à/to 1973 incl.Nom de la compagnie Name of the company MEUBLES B.N.L.INC.101966 R.MILLER & SONS TRANSPORT INC.33276 MISS POOLE.INC.6656 MITCH'S SPORTSWEAR INC.72360 MITROLAC MANUFACTURING LTD.10674 MITTEX LTD.72361 MOLLO RESTAURANTS LTD.72362 MONTREAL FACTORS CORPORATION LTD.49934 MONTREAL PRECISION WORKS LTD.72365 ALFRED NADEAU INC.6187 L.W.NOEL (QUEBEC) LIMITEE.64956 NORTH STAR CONSTRUCTION LTD.12381 NORTH-AMERICAN JEWELLERY STYLERS INC.26709 NORTHERN EQUIPMENT & AUTO PARTS CO.LTD.72223 NOUVEAU CINEMA ROSEMONT INC.78867 NYLON CENTRE LTD.73224 ODITAN MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).41093 L'OEUVRE DES LOISIRS DE STE-MARGUERITE INC.73923 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-ALEXI8, INC.30818 GUY PAGE AUTO INC.76872 PHELAN, DESTREMPES & REYNOLDS LIMITED.6298 PHILIE-CHARONNAT ENTREPRISES LTEE.27044 PHOENIX STUDIOS INC.6327 LES PLACEMENTS COLBERT INC.32591 PLACEMENTS PORT CARTIER INC.73041 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 197A, 106' année, n° SO 3581 Nom de la compagnie Name of the company PLACEMENTS VICALCO INC.04623 PLATING INDUSTRIES LIMITED.6469 PLOURDE & PLOURDE LIMITEE.6486 ! PLYMOUTH LABORATORIES INC.6493 POPEYE'S SNACK BAR INCORPORATED.6567 POSIDON RESTAURANT INC.32599 D.I.POULIOT, LTEE.6591 PREMIER BRAND CLOTHING CO.LTD.6637 PRINCESS SILKS INC.6706 PRINCETON SPORTSWEAR INC.6707 PRODUCTS AND SERVICES LIMITED.6823 LES PRODUITS ARTISTIQUES LIMITEE.6739 THE PROSPECTORS AND MINERS CLUB.6819 LES PUBLICATIONS M.B.C.INC.76884 PUBLICITE B & S PUBLICITY LIMITEE.6909 QUEBEC BROOM & MOP MANUFACTURERS ASSOCIATION INCORPORATED 6960 QUEBEC BUTCHERS SUPPLY INC.6961 THE QUEBEC CHARITY TRUST FOUND OF THE ARMY.NAVY.AND AIR FORCE VETERANS INCORPORATED \u2014 QUEBEC UNIT NO.33 6964 THE QUEBEC DIOCESAN (CHURCH OF ENGLAND) COUNCIL FOR SOCIAL SERVICE 6973 QUEBEC FIBRE COMPANY.LIMITED.6986 QUEBEC FISH BREEDERS LTD.6987 QUEBEC HIGHWAY & EXCAVATION LTD.6997 QUEBEC HOLDINGS CORPORATION.6998 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Québec.1967.1968, 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Chicoutimi.1964, 1965, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1958 incl.1964 à/to 1968 incl., 1970.1972, 1973 Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montréal.1956 à/to 1973 incl.Québec.1951.1967, 1968, 1972, 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1960 à/to 1965 incl.1967 1969, 1971, 1973 Montreal.1945 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Côte-de-la-Réserve.1947 à/to 1973 incl.Val-d'Or.1949 à/to 1973 incl.Chomedey.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1943 à/to 1973 incl.Québec.1946 à/to 1973 incl.Québec.1949 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 Québec.1946 à/to 1973 incl.Lanthier.1951 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl. 3582 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.Stay IS.1971, Vol.106, No.SO____ Nom de la compagnie Same of the company QUEBEC INTERLOCKING CEMENT PRODUCTS LIMITED.7004 QUEBEC IRON MINING COMPANY (NO PERSONAL LIABILITY) 7008 QUEBEC VELODROME INC.32600 QUEBEC WATERWAYS SIGHTSEEING TOURS COMPANY .6662 QUONG YICK RECREATION CLUB INC.6699 R.J.STAMPING CO.LTD.8074 RACK INDUSTRIES OF CANADA LTD.24426 RADAR CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 6730 RANSOM INC.72692 RAPID PRESS LIMITED.6812 RAPID TRANSPORT TERMINAL LIMITED.6816 RIGAUD - CONSTRUCTION, LIMITEE.6160 ROCH AUTO LTEE.72382 ROUSSEAU 4 BAILLARGEON LIMITEE.24474 RUBYLEE INC.10001 8 4 A MOTORS INC.73063 8T-VALLIER AUTOMOBILES INC.72846 J.E.SAMSON, INCORPOREE.7039 LA SANTE NATIONALE, INCORPOREE.7103 SAURIOL CONSTRUCTION CO.LTD.7121 H.SAURIOL LTEE.7122 MARGOT8AVARD INC.7131 SAXE BROTHERS INC.7163 WM.SEGAL INC.7267 Adresse Rapports non produit* Addreti Return* not filed Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Qucbeo.1966 à/to 1973 Incl.Québec.1966.1959 à/to 1972 incl.1972.1973 Montreal.1972 et/»nd 1973 incl.Verdun.1963 et/and 1973 Montreal.1957 à/to 1973 incl.Belleterre Village.1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1973 Kut.vid.1946 à/to 1973 incl.8t-Hilaire.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1962 à/to 1973 Incl.Montreal.1967.1964 à/to 1967 incl.1973 Montreal.1963 à/to 1973 incl.Québec.1963 à/to 1973 incl.Québec.1873 Montréal.1935 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 Incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1949 et / ^ 1973 Montreal.1947 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 197A, 106' année, n° 20 3583 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1933, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1938 à/to 1948 incl.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Princeville.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/tol973 incl.Montréal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1949 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl.Pointe-au-Pic.1973 Beloeil.1949 à/to 1973 incl.Québec.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 Rouyn.1947 à/to 1973 incl.Montreal.1948 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1946 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Longueuil.1964 à/to 1973 incl.Ayers Cliff.1948 à/to 1973 incl.Nom de la compagnie Name of the company C.SEGATORE BAKERY LIMITED.7261 SEGUIN CONSOLIDATED MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 7363 SELECT CHEMICAL CORPORATION.7273 SELECT CHEMICAL AND SOAPS INC.7274 SELECT CONSTRUCTION CO.LTD.7276 LE SERVICE ECONOMIQUE LTEE.26912 SERVICE FUR CO.LTD.7340 SERVICE INDUSTRIEL SERVICE INC.7342 SEVENTY SEVENTY-ONE ST.URBAIN LTD.7384 SHANNON SHOE FITTING COMPANY LIMITED.7393 8HARON DRESS MANUFACTURING INC.7397 THE SHAWINIGAN MINING AND SMELTING COMPANY .LIMITED 7419 ADJUTOR SIMARD INC.7574 PHILIP A.SINGER, LTD.6309 SIROIS LIMITEE.26876 SLADEN (QUEBEC) LIMITED.7651 SLEEPY GIANT MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 7657 THE SLIP-ON FOOTWEAR CO.LIMITED.7660 SLOPPY JOE'S STEAK HOUSE INC.7663 SMART MAID DRESS INC.7671 SMITH FLORAL SHOPPE INC.7699 THE JULIAN C.SMITH MEMORIAL FUND CORPORATION LA SOCIETE D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DES OEUVRES 29038 SOCIETE D'AIDE A LA JEUNESSE DE AYERS CLIFF.8319 3584 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of the company Address Returns not filed LA SOCIETE DES ARTS DE QUEBEC.Québec.19*6 à/to 1973 incl.8326 SOCIETE D'ASSISTANCE AUX IMMIGRANTS.Montréal.1949 à/to 1973 incl.8328 LA SOCIETE DU BON PARLER FRANÇAIS DE LA Trois-Rivières.1950 à/to 1973 incl.MAURICIE 8520 SOCIETE COLBERT, LIMITEE.Québec.1946 à/to 1973 incl.8361 SOCIETE EDUCATIONNELLE INCORPOREE.Montréal.1949 à/to 1973 incl.8369 LA SOCIETE D'OPTOMETRIE DE MONTREAL.Montréal.1948 à/to 1973 incl.8415 LA SOCIETE DE PEDIATRIE DE MONTREAL Montréal.1948 à/to 1973 incl.INCORPOREE 8417 LA SOCIETE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS DE Granby.1964 à/to 1973 incl.GRANBY INC.76917 LA SOCIETE DE PROTECTION NOTRE-DAME.Mont Laurier.1969 à/to 1973 incl.8428 LA SOCIETE ST JEAN BAPTISTE DE KENOGAMI, P.Q.Kénogami.1945 à/to 1973 incl.8443 LA SOCIETE DES SPECTACLES INCORPOREE.Montréal.1946 à/to 1973 incl.8456 LA SOCIETE SPORTIVE DE MATANE INC.Matane.1950 à/to 1973 incl.8457 SONNY SOBEL SALES LTD.Montreal.1963 à/to 1973 incl.73263 SOREL TRANSPORT LIMITEE.8orel.1947 à/to 1973 incl.8511 C.SORENSEN & SON LTD.Montreal.1950 à/to 1973 incl.8512 SOROKA INC.Lachine.1946 à/to 1973 incl.8515 L.SOUCIS, LIMITEE.Montréal.1948 à/to 1973 incl.8526 SOUTH SHORE FOREST PRODUCTS CO.LTD.Québec.1967, 1969 à/to 1973 incl.8548 SPAR-MICA CORPORATION LTD.Montreal.1960 à/to 1973 incl.(NO PERSONAL LIABILITY).27213 SPECIALTY SUPPLY SERVICE OF CANADA LIMITED .Montreal.1946 à/to 1973 incl.8597 SPORT ILLUSTRE INC.Montréal.1949 à/to 1973 incl.8631 SPORT ET LOISIRS LTEE.Montréal.1950 à/to 1973 incl 8633 SPORTS & LEATHER PRODUCTS LTD.Montreal.1947 à/to 1973 incl 8644 STANDARD HOTEL & HOSPITAL SUPPLIES INC.Montreal.1946.1964 à/to 1969 incl 8706 1972.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° SO 3585 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed STANLEY DRIVE YOURSELF SYSTEM INC.8750 STERLING TEAS & COFFEES LIMITED.8849 STOREY RETIREMENT NURSING HOMES.8523 SUCCESSORS TO THE SWIFT-COPLAN BUILDING LTD.8971 SYSTEME ECONOMIQUE DES CONSOMMATEURS LTEE.8525 TELEPHONE DE ST-HONORE-DE-SHENLEY INC.47275 TELEVISION MART INC.26451 H.T.TOBIASH LTD.72392 LOUIS TONDI.INC.32672 TRIANGLE REALTY CORPORATION.26726 UNITED RESOURCES INC.26227 THE VIKING INC.72395 WILSHIRE FLORISTS INC.25367 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Lachine.1950 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1950 à/to 1973 incl.St-Honoré-de-Shenley.1959, 1966, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Dorval.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1956.1959 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1958.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4.5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la oompagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date ACME PAD CO.LTD.AGENCE A.B.AUTONEIGE & SPORT LTEE.AHUNTSIC TRANSPORT LTD.AJUSTEMENT LAVAL LTEE.ALBERT NOVELTY CO.ALMAR CHOCOLATES LTD.L'AMICALE FRANCO-CANADIENNE.AMOS AUTOMOBILE ACCOMODATION INC.Montreal.29 10 1950 St-Jérôme.20 10 1965 Montreal.24 02 1966 Laval.21 04 1967 Montreal.28 04 1950 Montreal.22 06 1950 St-Hubert.19 01 1967 Amos.05 04 1966 35s(i QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Adirtu D»M Pont,Viau.16 04 1964 8t-Romuald.28 04 1960 Montréal.17 04 1964 Greenville.22 06 1964 Montreal.06 03 1960 Montréal.11 01 1968 Montréal.14 01 1965 Plessia ville.23 01 1961 Montréal.11 05 1965 Montréal.14 03 1966 Montréal.27 11 1959 Jonquière.30 04 1964 Québec.12 04 1962 Auatin.13 03 1962 Montréal.11 01 1961 Montreal.07 03 1968 Ste-Martine.07 06 1960 8t~Jérôme.09 12 1949 Montreal.08 11 1946 Trois-Rivières.17 03 1943 Arntfield.23 09 1944 Montréal.03 03 1946 Montreal.27 06 1943 Montreal.08 05 1926 Montreal.20 03 1936 Montreal.20 02 1942 Montréal.16 04 1946 Montréal.03 02 1946 Sillery.14 06 1946 Montreal.20 10 1942 Québec.27 11 1941 Montreal.26 06 1944 Montreal.19 01 1961 Montreal.08 04 1949 Montreal.16 03 1946 Montreal.06 08 1947 LES ANCIENS COMBATTANTS (QUEBEC) INC.ANDAL LABORATORIES LIMITED.AQUA REVUE LTEE.LES ARTISANS D'ARGENTEUIL INC.ASCOT LEATHER GOODS LTD.L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE ROUYN-NORAN DA INC.ASSOCIATION DES CABARETS ET HOTELS DE LA PROVINCE DE QUEBEC.ASSOCIATION DE HOCKEY DE PLESSISVILLE INC.ASSOCIATION DES JEUNES SCIENTIFIQUES.ASSOCIATION DES PARENTS D'ETUDIANTES DU COLLEGE SOPHIE-BARAT.LES ATELIERS D'ART LITURGIQUE LTEE.AU SABLONNET DE JONQUIERE LTEE.AU TISON D'OR INC.THE AUSTIN YOUTH ASSOCIATION INC.AUTOBUS METROPOLITAINS LTEE.B.S.G.INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.BEAUHARNOIS TRANSIT INC.BELAIR AUTOMOBILE LIMITEE.BELCOURT GOLD MINES LIMITED (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE).BELIVEAU MANUFACTURING LTD.BELLE-AURA MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).J.C.BELLEY LIMITEE.BELMONT 8PORTSWEAR CO.BENEDICTS CLUB INCORPORATED.BERGER 4 CHACHTER COMPANY LIMITED.M.BERGER 4 SONS LIMITED.BERGERON ELECTRIC INC.BERGERON 4 POTEL LIMITEE.BERGERVILLE WOOD INDUSTRIES INC.BERGS (ST JEROME) INC.J.ALPHONSE BERNIER LIMITEE.BEST EVER DRESS CO.LTD.BEST LUMBER CO.THE BETHLEHEM CO.BETTER HOMES BUILDERS LIMITED.BETTER SEATS CO. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3587 Nom de la compagnie A/ame of the company BETTY BELLE LTD.BETTY & MAXINE SPORTSWEAR LIMITED.LE BIEN-ETRE SOCIAL DE QUEBEC.LE BIEN-ETRE SOCIAL DE ST-JOSEPH D'ALMA.BIENVENUE TRANSPORT INC.BIJOUTERIE MARKO INC.J.A.BILODEAU LIMITEE.BILODEAU LIMITEE.CE.BINETTE LTEE.BIRDEE TOGS INC.BIRON-KNITTING MILLS LTD.BISHOP HOLDINGS LIMITED.GEORGE BIST LIMITED.BLAIS & CIE LTEE.BLANCHET & DALLAIRE LIMITEE.BLEY EMBROIDERY INC.BLOMINDON HOLDINGS LIMITED.BLOUSECRAFT INCORPORATED.BLUE BIRD SHOE LTD.BOARD OF TRADE OF THE MUNICIPALITY OF MANN.ULRIC BOILEAU & FILS LIMITEE.BOIS SUPERIEUR LIMITEE.BOISCLAIR & DRAGON LIMITED.LA BOITE \"DE FANTAISIE LIMITEE.J.ALPHONSE BOIVIN 4 COMPANY LIMITEE.MARCEL BOIVIN & COMPAGNIE LTEE.BOIVIN TRANSPORT INC.LA BONNE FOURCHETTE INC.BONNEAU AUTOMOBILE INC.BONNIE BURN CAMP LTD.BORDELEAU ELECTRICAL SUPPLIES LTD.BORIS FASHIONS INC.MAURICE BORTS INC.BOUCHARD & CIE (LIMITEE).D.BOUCHARD LIMITEE.BOUCHARD TRANSPORT LIMITEE.LES BOUCHERS \u2014 EPICIERS ASSOCIES LIMITEE.Adresse Incorporation Addresl Date Montreal.13 11 1944 Montreal.02 03 1945 Québec.29 03 1939 St-Joseph-d'Alma.12 02 1945 Douville.23 04 1964 St-Jérôme.16 07 1959 Montréal.18 12 1946 Québec.06 05 1930 Québec.01 10 1948 Montreal.27 06 1946 Berthierville.29 12 1937 Montreal.31 08 1948 Montreal.11 10 1949 Montebello.30 08 1946 Montréal.07 12 1943 Montreal.11 05 1944 Montreal.24 02 1966 Montreal.29 01 1936 Montreal.17 11 1930 Cross-Point.26 03 1942 Montréal.08 02 1945 Rouleau-Siding.20 10 1944 Montreal.20 11 1939 Montréal.07 06 1941 Lorretteville.26 08 1942 Québec.24 12 1947 Montréal.19 05 1944 Montréal.14 11 1961 Montréal.02 02 1948 West-Bolton.01 04 1946 Montreal.15 01 1951 Montreal.12 07 1950 Montréal.21 06 1949 St-Joseph-d'Alma.02 12 1947 Ste-Anne-des-Monts.22 02 1922 Drummondville.18 09 1946 Drummondville.09 04 1938 3588 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 197A, Vol.106, No.20 Nom de la compagnie Name of the company GERARD BOUFFARD LIMITEE.S.BOUFFARD LTEE.BOUGIE 4 FRERES LIMITEE.BOULANGERIE LACHUTE LTEE.BOULANGERIE ROYALE BAKERY INCORPOREE.H.BOULIANNE LIMITEE.BOURCIER MOTOR SALES INC.BOURGEOIS 4 BOURGEOIS, LIMITEE.LA BOUTIQUE DU CADEAU DE L'HOPITAL JEAN-TALON INC.LA BOUTIQUE EL PASO INC.BOYSCRAFT LIMITED.BOYSTOWN SHIRT MFG CO.LTD.H.E.BRADLEY COAL CORPORATION.BRAEMORE APARTMENT COMPANY.BRAIS INC.BRAM FUR CO.LTD.J.D.BRAULT LIMITEE.J.L.BRAULT LIMITEE.J.P.BRAULT LIMITEE.BRIDAL GOWNS INC.BRIDGEWATER LUMBER COMPANY LIMITED.BRIERE & BISSON LIMITEE.BRITISH CANADIAN INVESTMENT CORPORATION.BRITISH LOOMCRAFT (CANADA) LTD.BRITISH TEXTILES LIMITED.SAMUEL BROCK 4 SONS INC.BROOKSIDE INVESTMENTS LTD.BROTHERHOOD 4 SISTERHOOD OF TEMPLE SALOMON FREE LOAN ASSOCIATION.BROUILLET SAND 4 GRAVEL COMPANY LIMITED.BROWMAN REALTY INC.BROWN-BOUSQUET MINES, LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).J.A.BRUCE 4 CO.LIMITED.BRUNET 4 MITCHELL LTEE.THE GEORGE M.BRUNTON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.ALEX BRUUN LIMITED.BRUWOOD INC.BUANDERIE FEDERAL LAUNDRY LTD.Adresse Incorporation Address Date Granby.°6 °8 1948 Levis.02 12 1949 Cartierville.12 10 1948 Lachute.18 11 1947 Québec.09 06 1949 Arvida.21 07 1948 Val-d'Or.31 05 1949 St-Jean.31 01 1950 Montréal.29 01 1965 Montréal.27 07 1966 Montreal.28 02 1947 Montreal.09 08 1950 Montreal.28 12 1948 Montreal.26 06 1944 Québec.21 03 1945 Montreal.16 06 1936 Montréal.09 09 1948 Trois-Rivières.26 08 1949 Howick.30 01 1947 Montreal.19 09 1949 Québec.09 12 1946 Sherbrooke.07 06 1928 Montreal.08 10 1932 Montreal.29 09 1948 Montreal.29 12 1938 Montreal.13 02 1948 Montreal.07 01 1969 Montreal.16 05 1938 Montreal.23 09 1927 Montreal.27 04 1945 Montreal.27 06 1928 Montreal.19 10 1935 Pointe-Claire.03 04 1948 Québec.14 08 1928 Westmount.12 09 1946 St-Joseph-Sorel.16 10 1947 Montreal.15 10 1929 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3589 Nom de la compagnie Name of the company BUANDERIE DES LAURENTIDES LIMITEE.LA BUANDERIE ST-LAURENT INC.LA BUCHE L'ISLET, LIMITEE.BUCKINGHAM MINING CORPORATION.BUDGET FACTORS LTD.BUREAU DE COORDINATION DU TAXI.BURGE LAKE GOLDFIELDS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).JOHN BURNS & COMPANY LIMITED.BUSSIERES & FRERES LTEE.BUTTON INDUSTRIES LIMITED.BYRD BROTHERS LTD.CM.AND T.INCORPORATED.CACHE D'OR GOLD MINES (QUEBEC) LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).CADDIE LTEE.LES CADETS DE GRAND' MERE.LES CADRES L'ECLAIR LTEE.CAFE LE CHANTE CLERC INC.CAFE LIDO LIMITEE.CAFE AND RESTAURANT HOLDERS ASSOCIATION OF THE PROVINCE OF QUEBEC CAFE ST-MICHEL LTEE.CAFE VIDEO CORP.CALDWELL FRUIT CO.LTD.CALIFORNIA KNITWEAR LTD.CAMBRIDGE TAILORS LIMITED.CAMEO SPORTSWEAR LTD.CAMEO THEATRE INC.CANADA PEAT LIMITED.CANADIENNES PALETTES LTEE.CARLTON UPHOLSTERING CO.CARTIER ESTATE CORPORATION.LE CENTRE DES LOISIRS DU CAP-DES-ROSIERS INC.CENTRE DE LOISIRS DE ST-PAUL.CHAGNON A COURNOYER.LA CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-GODEFROY.CHAMPLAIN SPORTS INC.CHATEAU MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).Adresse Address Incorporation Date Ste-Adèle-en-Haut.22 02 1947 Montréal.23 11 1949 L'Islet.08 02 1946 Montreal.23 08 1945 Montreal.29 01 1949 Montréal.15 11 1948 Val-d'Or.27 04 1949 Montreal.26 09 1928 Normandin.26 03 1946 Montreal.13 07 1950 Montreal.19 11 1945 Montreal.26 02 1933 Vald'Or.15 10 1937 Québec.27 01 1947 Grand'Mère.06 03 1962 Québec.09 12 1948 Montréal.14 12 1946 Hull.21 05 1926 Montreal.27 01 1943 Montréal.09 01 1946 Montréal.20 06 1946 Montreal.25 11 1939 Montreal.01 04 1948 Montreal.10 10 1946 Montreal.16 06 1944 Montréal.14 01 1948 Rivière-du-Loup.27 01 1940 Montréal.21 11 1966 Montreal.09 01 1951 Montreal.09 06 1950 St-Alban-du-Cap-des- 27 01 1967 Rosiers.St-Paul-de-Montminy.21 03 1963 Drummondville.13 06 1962 St-Godefroy.02 11 1964 Québec.22 01 1951 Montreal.21 06 1960 3590 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 Nom de la compagnie Adresse Incorporation Name of the company Addrcta Date LA CIE DE BOIS DE STE FELICITE LTEE.\t\t20\t09\t1946 \t\t24\t09\t1940 \t\t22\t12\t1930 T.A CTF DFS TARACS JAUNE-CLAIR DE JOLIETTE LTEE.\t\t18\t12\t1933 CTTATiFT TMVPQTMFMT CORPORATION\t\t15\t08\t1950 \t\t24\t05\t1950 CTATRF-ANNF DRESS CO T/TD\t\t22\t01\t1946 CT.ASSV OF CANADA T.ÏMTTED\t\t22\t12\t1960 CLORAS CONSTRUCTION INC.\t\t20\t04\t1965 CTJTR D'AVTATTON SHERBROOKE INC\t\t02\t08\t1963 I,F.CLUB CANADA LIMITEE\t\t26\t04\t1917 \t\t09\t10\t1964 LE CLUB DE GOLF DE LA BAIE DES CHALEURS INC.\t\t05\tOP.\t1972 CLUB DE GOLF DE ST-BONIFACE.\tSt-Boniface-de-Shawi-nigan.\t18\t12\t1969 CLUB OPTIMISTE METROPOLITAIN-HAUT D'ANJOU INC\t\t21\t06\t1972 CLUB OPTIMISTE REPENTIGNY INC.\tRepentigny.\t24\t02\t1967 LE CLUB RAQUETTEUR L'ALGONQUIN.\tManiwaki.\t21\t06\t1961 CLUB DE ST-EMILE INC.\t\t22\t04\t1966 CLUB SOCIAL DES CAPILLICULTEURS DU CANADA____\tQuébec.\t13\t10\t1964 CLUB SOCIAL ET SPORTIF DU LAC AYLMER INC.\tDisraeli.\t28\t09\t1966 LE CLUB SPORTIF DE DAVELUYVILLE INC.\t\t12\t01\t1961 CLUB SPORTIF RUISSEAU ROUGE INC.\tMagog.\t02\t06\t1967 LE CLUB DE TENNIS DU MOULIN INC.\tCap-de-la-Madeleine.\t30\t05\t1950 COLERAINE ASBESTOS LIMITED.\t\t13\t07\t1966 COMITE CHEMIN D'HIVER DE STE-JULIE DE ST-GUILLAUME\tSt-Guillaume.\t24\t10\t1946 LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE NICOLET.\tNicolet.\t10\t01\t1944 COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-BONAVENTURE LIMITEE.\tSt-Bonaventure-d'Upton\t26\t02\t1946 LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-DENIS SUR-RICHELIEU INC.\tSt-Denis sur-Richelieu.\t30\t01\t1945 LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DES ST-OURS INCORPORE.\tSt-Ours.\t17\t12\t1945 LE COMITE DES CHEMINS D'HIVER DE ST-ZEPHIRIN DE COUR-VAL INCORPORE.\tSt-Zéphirin (Yamaska).\t22\t02\t1946 LE COMITE DE CITOYENS DE LATERRIERE INC.\t\t29\t03\t1972 COMITE DE DEVELOPPEMENT DE CABANO.\t\t27\t00\t1950 1951 COMITE D'ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER DE ST-BRUNO, COMTE DE KAMOURASKA.\tSt-Bruno.\t24\t01\t COMITE DES LOISIRS STE-CECILE.\t\t10\t07\t1948 COMITE DES LOISIRS DE STE-MARIE SALOME.\t\t27\t05\t1949 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3591 Nom de la compagnie Name of the company LE COMITE DES LOISIRS DE VAL ST-PIERRE.COMITE DU MONUMENT DE LA DAUVERSIERE.COMMERCIAL ENTERPRISES INC.COMMERCIAL OPTICAL COMPANY LIMITED.COMMERCIAL RADIO LABORATORIES LIMITED.COMMODITIES INCORPORATED.COMMONWEALTH COLOR AND CHEMICAL CO.LIMITED.COMPAGNIE BELISLE 4 ALLARD LIMITEE.COMPAGNIE DE BISCUITS AETNA LIMITEE.COMPAGNIE DE BOIS BRISSON, LTEE.LA COMPAGNIE DE CONSERVES DE NAPIER VILLE, LIMITEE.LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION BOUCHARD ET ROULEAU.LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION DE ST-GUILLAUME LTEE.LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION SENNEVILLE 4 ST-ANDRE LTEE.LA COMPAGNIE DES GRANDS SPECTACLES INC.LA COMPAGNIE DE PUBLICATION LE FLAMBEAU INC.LA COMPAGNIE DE TELEPHONE LOCAL DE STRATFORD.LES COMPAGNONS DE L'ART.COMPTOIR DES MARCHANDS INC.LES COMPTOIRS GRENIER INC.COMPTOIRS-UNIS DU QUEBEC, INCORPORE.CON-AIR-CON LIMITED____.CONCRETE WATERPROOFING AND RESTORATION LIMITED.CONFEDERATION REALTIES INCORPORATED.CONGRESS IMPORT 4 NOVELTY INC.LA CONSERVERIE DE CHARLESBOURG LTEE.CONSOLIDATED SALES CORPORATION.CONSOLITED FUR INC.CONSTANTINEAU, PELLETIER ET WILSON, LIMITEE.LA CONSTRUCTION DE LEVIS LIMITEE.CONSTRUCTION PREFABRIQUEE LIMITEE.CONSUMERS INDUSTRIAL MINERALS, LIMITED.CONSUMERS PRODUCTS CORP.CONTINENTAL ENTERPRISES LTD.CONTINENTAL LABORATORIES INC.CONTINENTAL METALS CORPORATION.CONTRACTORS UNIFORM COMPANY LIMITED.Adresse Incorporation Address Date ValSt-Pierre.14 12 1954 Montréal.27 11 1942 Montreal.16 03 1946 Montreal.17 10 1927 Bagotville.09 04 1948 Montreal.22 04 1948 Montreal.31 12 1930 La-Baie-du-Fèvre.14 12 1944 Montréal.16 06 1937 Rimouski.30 08 1946 Napierville.28 02 1929 St-Jérôme-de-Matane.28 12 1937 St-Guillaume.13 03 1946 Coteau-Rouge.14 02 1946 Montréal.26 04 1967 Mont-Laurier.15 08 1967 Stratford.25 10 1925 Rimouski.19 03 1947 Québec.30 09 1943 Montréal.21 01 1948 Str-Basile-le-Grand.19 06 1945 Montreal.03 10 1947 Montreal.08 03 1945 Montreal.20 03 1944 Montreal.20 11 1942 Charlesbourg.21 05 1946 Montreal.30 01 1947 Montreal.____ 17 01 1949 Montréal.01 04 1920 Levis.;.15 03 1945 Drummondville.21 08 1963 Montreal.09 06 1944 Montreal.22 08 1944 Montreal.,.08 04 1942 Terrebonne.,.20 11 1946 Montreal.16 07 1945 Montreal.13 04 1942 3592_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, MA, Vol.106, No.SO___ Nom de la compagnie Name of the company CONVOY SILKS LTD.EMILE COOL 4 FILS LIMITEE.COOPER-HIRSCH INC.CORONA HOSIERY CORPORATION.CORONET GOLD MINE LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).CORONET HANDBAGS INC.LA CORPORATION DES GROSSISTES DE CHICOUTIMI.CORPORATION DE L'INSTITUT DU RADIUM DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL ET DE LA PROVINCE DE QUEBEC.LA CORPORATION DES PROPRIETAIRES DU LAC DES SEPT-ILES.LA CORPORATION DE PROTECTION DE DOCUMENTS.CORPORATION RECREATIVE D'OUTREMONT.CORPORATION SERVICES LTD.CORPS DE TAMBOURS ET CLAIRONS LES MARQUISES INC.COSAFI LTEE.COSMO JEWELLERY 4 NOVELTY CO.C.COTE LIMITEE.COTE 4 FILS AUTOMOBILE LIMITEE.GERARD COTE AUTOMOBILES INC.PHIL COTE LUMBER LIMITED.COTE SHOE LIMITED.COTTON MOTOR SALES CO.LTD.ARTHUR COUILLARD LTEE.J.A.COULOMBE 4 CO.LIMITED.COUNTRY HOUSING COMPANY.COURAGEOUS HOLDINGS LIMITED.COURVILLE 4 DESPAROIS LTEE.COUVRETTE 4 CASONI INC.ORABTREE PLASTICS LIMITED.CRAFTMILLS NOVELTIES LIMITED.CRAFTWORKS TRADING CORP.CRAVEN CLOTHES 4 SPORTSWEAR INC.CREATIVE ASSOCIATES INC.CREDIT INDUSTRIEL INC.LE CREDIT SOCIAL DU QUEBEC.CREMERIE MARIEVILLE LIMITEE.CREMERIE NOTRE-DAME, LIMITEE.LES CUIRS TEMIS LIMITEE.Adresse Incorporation Address Date Montreal.02 07 1948 Verdun.04 01 1946 Montreal.23 01 1939 Québec.03 10 1946 Montreal.02 06 1950 Montreal.24 01 1941 Chicoutimi.07 02 1945 Montréal.04 03 1926 Québec.19 04 1940 Montréal.12 08 1942 Outremont.09 01 1945 Montreal.06 02 1937 Ste-Thérèse.20 09 1968 Montréal.11 07 1946 Montreal.29 08 1945 St-Hilaire.04 08 1949 Québec.t> 14 02 1947 St-Jovite.26 01 1948 Roberval.01 03 1948 Montreal.27 12 1944 Québec.29 07 1949 Beauharnois.05 10 1949 Québec.10 05 1926 Montreal.18 09 1946 Amos.21 06 1937 Montréal.09 03 1945 Parent.15 07 1947 Crabtree Mills.11 07 1949 Montreal.20 01 1944 Montreal.17 07 1942 Montreal.27 04 1949 Montreal.07 10 1963 Montréal.20 09 1948 Shawinigan Falls.12 12 1946 Marieville.24 12 1947 Montréal.08 08 1946 Témiscouata.11 01 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai MA, 106' année, n° 20 3593 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Incorporation Address Date Montreal.11 07 1950 Montréal.07 06 1938 Montreal.08 08 1968 Montreal.11 03 1969 Montreal.02 12 1963 St-Basile-le-Grand.14 04 1967 Montréal.10 02 1947 Montréal.06 12 1945 Montréal.23 06 1949 Montreal.09 05 1940 Drummondville.12 05 1950 Montréal.15 08 1950 Montreal.13 01 1945 Québec.11 05 1939 Québec.10 10 1946 La Malbaie.07 06 1949 Eastman.10 02 1021 Longueuil.08 02 1946 Montréal.02 08 1966 Montréal.16 05 1945 Montréal.21 04 1969 Aima.29 04 1972 Montréal.06 06 1944 Québec.10 06 1969 Rock Forest.19 07 1968 Québec.10 08 1937 Montreal.18 04 1967 Chicoutimi.16 11 1961 Montréal.21 03 1966 Montréal.28 10 1964 St-Timothée.13 02 1964 Val-David.13 04 1965 Montréal.27 06 1966 Montreal.06 04 1965 Amos.04 12 1959 Montreal.18 02 1966 Montreal.21 06 1950 THE CUSTOM SHOP INC.CYCLES GACHON INCORPOREE.DAISY DEE CLEANERS INC.DAN AUTOMATIC ALARM INC.DEL-CAT CORPORATION LTD.THE DIAMOND STEER LTD.DORSEY-PICARD INC.ROMEO DORVAL LIMITEE.PAUL DOZOIS LTEE.DRESS CONTRACTORS ASSOCIATION.DRUMMONDVILLE ATHLETIC ASSOCIATION INC.DUBE & DUCHARME LIMITEE.DUCAS BROS.FURRIERS INC.LUDGER DUCHAINE INC.DUCHESNE & BOUCHARD LIMITEE.DUGAY FRERES LTEE.EASTMAN HARWOOD LUMBER COMPANY LIMITED.LES EBENISTERIES LONGUEUIL LIMITEE.ECONO LIMITEE.EDGEWATER BEACH HOTEL INC.EDIBEC INC.EDIFICE GODIN LTEE.L'EDITION LA VICTOIRE LTEE.LES EDITIONS DU MERCREDI INC.EK-CE-LAN SPORTS INC.ELECTROMATIC ENGINEERING CO.LIMITED.ENCORE-MEAT PRODUCTS LTD.LES ENTREPRISES CENTRALES INC.LES ENTREPRISES J.R.LEGAULT LTEE.LES ENTREPRISES JEANNE D'ARC LTEE.LES ENTREPRISES LARELA INC.LES ENTREPRISES PARTICIPEX INC.LES ERECTIONS DE CHARPENTES DUBOIS INC.EXUMA LIMITED.FAROMALE INC.FELICI-PERRERA IMPORTS INC.FITE RITE TAILORS INC. 3594_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.SO___ Adresse Incorporation Addren Date Montreal.10 06 1966 Lachine.\" 02 1969 Gatineau.21 05 1971 Montreal.10 04 1947 Knowlton.17 05 1966 Chicoutimi-Nord.10 10 1972 Laval.20 10 1965 Aima.30 01 1957 La Patrie.26 07 1950 Montreal.14 08 1950 Montreal.10 01 1951 Montreal.12 01 1951 Montreal.19 01 1951 Montreal.10 02 1967 Montreal.26 06 1950 Sherbrooke.21 03 1972 Montreal.20 01 1940 Granby.22 08 1950 Montreal.03 06 1950 Montreal.15 02 1946 Sillery.17 10 1947 Gaspé.05 01 1951 Québec.23 03 1942 Montreal.14 08 1950 Sherbrooke.01 04 1949 St-Laurent.01 05 1950 Montreal.13 02 1946 Montreal.07 03 1949 Montreal.13 07 1946 Montreal.13 07 1950 Stanbridge.27 06 1966 Trois-Pistoles.15 03 1966 Hull.24 01 1961 Loretteville.02 02 1951 Montreal.19 06 1964 Québec.24 10 1963 Montréal.19 07 1967 Nom de la compagnie Name of the company FLOR-NOR EXPLORATIONS' LTD.FOMA MANUFACTURERS AND AGENTS LIMITED.FONDEX LTEE.FORM FIT SHOULDER PAD LTD.FOSTER CONSTRUCTION INC.FOYER DE LA GAIETE DE CHICOUTIMI-NORD.GACO INC.ZOEL GAGNON LIMITEE.GARAGE LA PATRIE INCORPOREE.GAYMONT (INTERNATIONAL) LIMITED.GENERAL NOTIONS INC.SAMUEL GIBSON INC.GLENVIEW FRUIT COMPANY.GLOBAL CAMPING & PARKING INC.GLORY SHIRT MFG.CO.LTD.THE GOLDEN PHOENIX RESTAURANT LTD.GRAD GARMENT LIMITED.GRANBY GENERAL STORE LTD.GRAWMONT MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).GRIMMER SERVICES (LIMITED).GRONDIN & SA VARY LIMITED.GUIGNION BROS.LTD.LE GUILDE DES REGRATTIERS DU QUEBEC.HALPENNY LIMITED.L'HARMONIE CADETTE DE SHERBROOKE.HART MOTORS (CARTIERVILLE) LIMITED.HEMISPHERE TRADING CORP.HENRICO CONSTRUCTION CORPORATION.HILTOY COMPANY INC.T.F.HOGG & CO.LTD.HOTEL STANBRIDGE INC.HOTEL VICTORIA (TROIS-PI8TOLES) INC.HULL CONCRETE PRODUCTS LIMITED.HURON FUR DRESSERS LIMITED.I.B.I.SYSTEMS INC.LES IMMEUBLES ROUTEXPRESS INC.IMPRIMERIE-LITHOGRAPHIE CHARTRAND LTEE. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3595 Nom de la compagnie Mime of the company INDIAN LACROSSE CLUB LTD.LES INDUSTRIES DU BOIS INC.INDUSTRIES METALLURGIQUES DE ROXTON LIMITEE.LES INDUSTRIES OUELLET LTEE.L'INFATIGABLE.INSTITUT DE DANSE DES BOIS FRANCS INC.J.G.AUTOMOBILE LTEE.LA JEUNE CHAMBRE DE LAPRAIRIE INC.LES JOINTS INDUSTRIELS METROPOLITAINS LTEE.LES JOURNAUX ASSOCIES S.F.INC.JUNIOR MAID LINGERIE MFG.LTD.LA COMMERCIALE (INCORPOREE).LABORATOIRE ALGERINE LIMITEE.LES LABORATOIRES BIO-BACTO LTEE.LAC MASSON GOLD AND COUNTRY CLUB, INC.J.C.LACOMBE INC.LADY STELLA OF FIFTH AVENUE LTD.J.P.LAJEUNESSE INC.LAKE ST.JOHN AND CHIBOUGAMAU TRANSPORT LIMITED.LAKESIDE HOMES INC.P.A.LANGELIER LIMITEE.LAROFOR INC.LAURIER REMBOURRAGE INC.LAVAGE DE VITRES CAMPEAU WINDOW CLEANING INC.S.N.LAZARUS A CO.LTD.LEMOINE CHIBOUGAMAU MINING CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY).ADELARD A GUSTAVE LEPINE, INC.JACK LEWIS INC.LIAISON INC.LIBRAIRIE VACHON LIMITEE.LIDO PRODUCTS COMPANY LIMITED.LA LIGUE D'AVANCEMENT CIVIQUE.LIGUE INDEPENDANTE CATHOLIQUE DE MONTREAL.LA LIGUE PANAMERICAINE DU CANADA (QUEBEC).LA LIGUE POUR LA SAUVEGARDE DE L'INDUSTRIE LIBRE.LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DE GRANBY INC.Adresse Incorporation Address Date Caughnawaga.28 01 1965 Ste-Thérèse-de- 08 11 1967 Blain ville Roxton Falls.28 07 1950 Chicoutimi.05 06 1966 St>Hyacinthe.23 12 1938 Victoriaville.13 05 1965 Dolbeau.25 06 1963 La Prairie.31 05 1967 Montréal.29 10 1964 Ste-Foy.31 07 1964 Montreal.22 05 1950 Montréal.12 03 1947 Québec.24 04 1950 Ste-Foy.31 07 1967 Montréal.12 08 1957 Sorel.11 04 1968 Montreal.18 05 1967 Québec.09 06 1951 Roberval.13 06 1950 Montreal.29 05 1967 Montréal.25 04 1950 Laval.21 10 1966 Québec.06 10 1966 Montréal.10 01 1951 Montreal.09 05 1950 Montreal.07 05 1956 Québec.07 05 1945 Montréal.26 05 1936 Montréal.04 06 1942 Québec.22 11 1928 Montreal.26 11 1946 Montréal.07 07 1948 Outremont.17 11 1948 Québec.05 10 1945 Montréal.04 05 1943 Granby.28 02 1950 3596 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.30 Nom de la compagnie Name of the company LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DES TROIS-RIVIERES, INC.LIGUE REGIONALE DE BALLE MOLLE SENIOR DE LA RIVE SUD INC.LIKE-NU FUR BLENDING & DYEINS LTD.LIMOGES, PICHE, ALARIE LTEE.LIMOILOU ELECTRIQUE LIMITEE.LINDA MANUFACTURING INC.LINGERIE « DU JOUR » INC.LINGERIE SALES INCORPORATED.LINKO INVESTMENT LTD.JOS LIPARI LIMITEE.S.LIPSON & CO.THE LITTLE CUTIE INC.THE LITTLE THEATRE OF QUEBEC, INCORPORATED.LOCAL SALVAGE CORPORATION.LODZ ASSOCIATION.LOISIRS NOTRE-DAME.LES LOISIRS DE ST-PHILEMON INC.M.G.COMMUNICATIONS VISUELLES INC.R.MACLEAY & COMPANY LIMITED.MAIN HEBREW DELICATESSEN INC.LA MAISON ROUTHIER INC.MAMIE MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).MARCHAND CYCLO MASSAGE DE QUEBEC INC.MARCHE JARRY INC.PETE MARK INC.MARTIN ENGINEERING INCORPORATED.PENNY MASON (CANADA) LTD.PHILIPPE MAZIADE LTEE.METRO EXCAVATION (1966) LIMITEE.METS DE LACHINE INC.MEUBLES & QUINCAILLERIE BEAUCHAMP & FRERES INC.MIL-BOY LIMITED.MINOLET BRANDS INC.GEO.MINVILLE & ASSOCIES LTEE.MODERN FASHION LIMITED.MODERNFOLD (CANTON DE L'EST) LTEE.MONALEA BEACH BUNGALOWS INC.Adresse Incorporation Address Date Trois-Rivières.24 12 1934 Lauzon.28 06 1966 Montreal.24 05 1950 St-Jérôme.06 02 1948 Québec.07 11 1945 Montreal.23 11 1944 Montréal.19 10 1948 Montreal.23 05 1950 Montreal.16 11 1966 Montréal.15 04 1946 Montreal.03 07 1947 Montreal.03 12 1942 Québec.11 10 1939 Montreal.18 10 1944 Montreal.26 09 1944 Montréal.11 06 1949 St-Philémon.04 01 1967 Montréal.01 10 1969 Montreal.09 05 1960 Montreal.30 12 1960 Trois-Rivières.08 01 1965 Montreal.15 08 1966 Giffard- .04 07 1967 Montréal.10 07 1951 Québec.21 04 1949 Montreal.16 04 1932 Montreal.28 08 1946 Chicoutimi.18 01 1951 Montréal.11 02 1966 Lactone.21 04 1965 Ormstown.19 01 1971 Montreal.04 05 1950 Montreal.10 01 1951 Montréal.16 05 1963 Québec.07 07 I960 Sherbrooke.23 05 1956 Montreal.04 06 1959 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106- année, n° SO 3597 Nom de la compagnie Name o{ Iht company MONICA DISTRIBUTORS INC.MONTREAL TERRAZO TILE 4 MARBLE LIMITED.MONTREAL TILE TERRAZZO AND MARBLE EMPLOYERS' ASSOCIATION MONTY 4 FRERES LTEE.MOTEL LA BOURGADE INC.MULTI-DISTRIBUTION INC.NAN8U MANAGEMENT CORP.NARIMAC LIMITEE.NATAKI CORPORATION.NEUVICO LTEE.NEW YORK GARMENT INC.NICK'S DISCOUNT DEPARTMENT STORE LTD.NORTHAMERICAN CASING CORPORATION.NORTHERN RESORTS ASSOCIATION OF THE LAURENTIANS.NORTHERN SALES COMPANY.NORTHERN TANK HAULERS LTD.NORTHERN TIMBER COMPANY LIMITED.NORTHMOUNT SALES LTD.NORWEGIAN WOODCRAFT LIMITED.NOUVELLE ORGANISATION EN CONSTRUCTION INC.NOVA KNITTING LIMITED.NOVA REALTIES INC.NOVA SCOTIA COAL SALES LTD.NOVAMINES CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY).NOVELTY FABRICS INC.NOVELTY HANDBAGS LIMITED.NOVELTY MFG.CO, LTD.NOVO BROOM 4 MOP 8UPPLIES CORPORATION.NU-MODE NOVELTY INC.NUN'S ISLAND THEATRE INC.NU-STYLE CLOTHING CO.NU-TONE PRODUCTS LIMITED.NU-WAY FOOD PRODUCTS INCORPORATED.NU-WAY MEAT MARKET LTD.L'OEUVRE DES LOISIRS DE LA CITE DE CHICOUTIMI.L'OEUVRE DU SERVICE FAMILIAL.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEU DE ST-JEAN-PORT-JOLI INCORPOREE Adresse Incorporation Addrtn Date Montreal.06 08 1964 Montreal.18 01 1961 Montreal.16 01 1951 Marieville.20 07 1950 Dorion.13 12 1971 Montréal.10 09 1969 Montreal.12 01 1962 Montréal.14 07 1963 Montreal.16 11 1971 Neuville.08 02 1968 Montreal.02 06 1950 Montreal.13 08 1971 Montreal.07 06 1940 Ste-Agathe.01 12 1948 Montreal.02 02 1944 Montreal.06 01 1951 Montreal.04 12 1942 Montreal.14 08 1944 Lachine.02 05 1946 Montréal.19 12 1944 St.Johns.21 06 1946 Montreal.19 07 1946 Montreal.15 03 1937 Montreal.04 04 1937 Montreal.04 04 1946 Montreal.17 04 1946 Montreal.13 01 1934 Montreal.27 10 1942 Montreal.03 03 1945 Montreal.14 06 1968 Montreal.14 12 1944 Montreal.04 03 1949 Montreal.06 04 1949 Montreal.17 01 1936 Chicoutimi.07 06 1946 Montreal.06 11 1948 St-Jean-Port-Joli.04 07 1946 :r>ï)s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 Nom de la compagnie Same of the company L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX D'ARMAGH.OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE D'IBERVILLE INCORPOREE L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET COLONIES DE VACANCES D'ARVIDA L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX ET D'EMBELLISSEMENT DE BAGOTVILLE L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE MONTMAGNY INC.L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX SAINT-JEAN-BOSCO (O.T.J.DE JOLIETTE) L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE SAINT-LAURENT.OFFICE SALES 4 SERVICES CO.LTD.OKA WOOD PRODUCTS LIMITED.ONAGON INVESTMENTS LIMITED.THE ONYX 4 METAL PRODUCTS LIMITED.THE OPTIMIST CLUB OF VERDUN INC.ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE MONTREAL.ORDER SONS OF ITALY BUILDING ASSOCIATION INCORPORATED ORE MONTE MINE INC.(NO PERSONAL LIABILITY).OREMAR GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).ORFORD MINING COMPANY LIMITED.ORGUES O.JACQUES (LIMITEE).ORIGINAL KNISH BAKERY LTD.ORLAND GOLD MINES (QUEBEC) LIMITED.OSISKO LUMBER LTD.OTTMAN GOLD MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).OUELLETTE GLOVE WORKS LTD.THE OUTREMONT CURLING CLUB INCORPORATED.OVERBURDEN DRILLING COMPANY LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) THE OVERSEAS AID ASSOCIATION.INC.THE OXFORD CLUB.P.A.T.CHEMICALS LIMITED.P.4 P.MANUFACTURING CO.LTD.EDOUARD PAGE LIMITEE.PAGE 4 PAGE LTEE.PALAIS SOHMER LIMITEE.PALM CLUB INC.PALMER REALTIES INCORPORATED.PALMER8 8ALON LTD.Adresse Incorporation Address Date Armagh.03 10 1944 Iberville.01 10 1948 Arvida.14 06 1944 Bagotville.04 12 1946 Montmagny.11 08 1949 Joliette.31 10 1947 St-Laurent.18 03 1938 Montreal.10 01 1949 Montreal.03 10 1945 Montreal.05 11 1936 Montreal.02 03 1938 Verdun.19 01 1948 Montréal.20 11 1946 Montreal.30 06 1944 Montreal.25 01 1937 Montreal.11 02 1947 Sherbrooke.17 07 1942 Village de la Providence.17 08 1938 Montreal.05 07 1948 Montreal.03 07 1937 Rouyn.01 02 1949 Rouyn.04 09 1937 Marieville.18 02 1948 Outremont.14 12 1939 Val d'Or.14 01 1946 Montreal.30 05 1932 Montreal.04 03 1938 Outremont.21 09 1948 Montreal.17 10 1947 Verdun.11 01 1928 Montréal.23 11 1962 Montreal.19 09 1935 Montreal.19 06 1937 Montreal.04 10 1948 Montreal.12 01 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" 20 3599 Nom de la compagnie Name of the company PAM TRADING LIMITED.PAN CONSTRUCTION INC.PAN INVESTMENT LIMITED.PAN-AMERICAN IMPORTERS & EXPORTERS INC.PAPINEAU HOLDING CORPORATION.JOS PAQUET LIMITEE.PARADIS AUTOMOBILE LTEE.PARADIS & FARLEY INC.PARAMOUNT CLUB INCORPORATED.PARAMOUNT CLUB INCORPORATED.PARAMOUNT FOOTWEAR LIMITED.PARAMOUNT LEATHER GOODS CO.INC.PARAMOUNT SERVICE ENTERPRISES LTD.PARAMOUNT TRADING CORPORATION.PARAPLASTICS LTD.PARFUMERIE L.T.PIVER LIMITEE.PARFUMERIE LONGCHAMPS LTD.PARIS FUR CO.INC.PARIS LABO LIMITEE.LUCIEN PARIZEAU & CIE LTEE.PARK LANE GOWNS INC.PARK TOBOGGAN A SKI CLUB LIMITED.PARKTOWN MFG.LTD.PARKWAY AUTOMOBILES LIMITED.PASTEL GARMENT MANUFACTURING COMPANY LTD.PAT-ANN JUNIORS INC.A.W.PATENAUDE INCORPOREE.PATRICIA APARTMENTS INC.LE PATRONAGE DE JONQUIERE.LE PAVILLON DES POINTES BEAUDET LTEE.PEAR-LIT MALARTIC MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).PECO DYEING INC.PEERLESS CANDIES LTD.PEERLESS FURNITURE MANUFACTURING CO.LTD.PEGGY ANN SHOPS INCORPORATED.LES PEINTURES IDEALES INC.PELCHAT - GAUTHIER LIMITEE.Adresse Incorporation Address Date Montreal.29 06 1944 Québec.08 02 1947 Québec.10 10 1945 Montreal.21 01 1946 St-Jérôme.20 03 1964 Québec.14 04 1942 Montréal.27 01 1945 Montreal.30 12 1936 Montreal.26 02 1938 Montreal.15 03 1946 Montreal.06 06 1930 Montreal.09 12 1949 Montreal.05 02 1945 Montreal.29 04 1946 Montreal.19 06 1946 Montréal.26 06 1937 Montreal.07 05 1945 Montreal.10 01 1942 Montréal.08 04 1948 Montréal.18 11 1943 Montreal.05 10 1944 Montreal.15 01 1925 Montreal.27 06 1944 Montreal.23 04 1949 Montreal.18 06 1946 Montreal.27 11 1944 Montréal.30 12 1929 Montreal.27 10 1949 Jonquière.22 02 1947 Victoriaville.08 02 1946 Montreal.24 12 1936 Montreal.08 06 1950 Montreal.20 01 1947 Montreal.04 10 1944 Montreal.18 05 1949 Québec.14 03 1967 Montréal.19 07 1945 3600 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO__ Adresse Incorporation Address Date Montréal.23 09 1948 Montreal.07 08 1946 Québec.09 03 1939 Montreal.09 05 1949 Montreal.22 02 1940 Montreal.13 10 1949 Montreal.23 04 1945 Montreal.03 11 1947 Montreal.21 06 1946 Montreal.09 06 1943 Montreal.15 05 1963 Montreal.26 11 1940 Laval.21 09 1966 Montréal.26 08 1946 Montreal.13 02 1947 Montréal.04 04 1967 Pierrefonds.24 05 1960 St-Basile-le-Grand.02 12 1968 Montréal.14 09 1972 Québec.20 06 1950 Dorion-Vaudreuil.22 03 1961 Montreal.14 03 1956 Pointe-Claire.25 01 1971 Montreal.22 06 1960 Val-David.23 02 1965 Montreal.28 09 1938 Alma.17 11 1966 Montreal.19 07 1960 Montreal.24 11 1948 Cap-Santé.09 05 1967 St-Raphaël-de-1'Ile 07 09 1965 Bizard.Rimouski.05 07 1950 Laval.26 10 1966 Montreal.10 01 1951 Montreal.01 03 1966 Montreal.11 01 1961 Nom de la compagnie Name Come.11 10 1949 Montreal.18 02 1946 Montreal.06 08 1946 Rouyn.20 12 1937 Montreal.21 04 1942 Montreal.08 06 1931 Montreal ,.29 04 1937 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3603 Nom de la compagnie Name of the company H.WALFORD LIMITED.WALGROVE LIMITED.'.JAMES WALKER HARDWARE COMPANY.WALLEY LUMBER CO.LTD.WALTER HATS LTD.J.WARD ASBESTOS CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) WARTIME ACCIDENT PREVENTION EMERGENCY SERVICE INCORPORATED WASHINGTON CLUB INCORPORATED.WASHINGTON GOLDS LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WATSON & MARTIN LIMITED.WEIR'S GARAGE LIMITED.WEIR'S MOTOR SALES LTD.S.WEISER LTD.WELLINGTON THEATRE LIMITED.WEST AERONAUTICAL DEVICES INC.WEST SHORE GOLD MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).WESTBORO INCORPORATED.WESTERN SUPPLIES LIMITED.WESTERN TOTALIZATOR MFG INC.WESTMOUNT FURS INC.WESTMOUNT GROCERY COMPANY.WESTMOUNT PARK MANOR CORPORATION.WHEELER CONSTRUCTION LTD.THE WHITE DAIRY MILK BAR LTD.W.H.WHITE LIMITED.WHOLESALE SOLID FUELS BUREAU INC.GEO.WHYTE INC.THE WIGWAM FISH AND GAME CLUB INCORPORATED.WILL & PILON LIMITEE.WILLIAMS 8HARE CORPORATION (QUEBEC) LTD.WILLIAMS TRANSPORTATION COMPANY LIMITED.WILMOT ENTERPRISES LTD.WILSON EQUIPMENT CO.LTD.GEO.R.WILSON LIMITED.WILSON MACHINERY & SUPPLY COMPANY.WILLIAM WILSON COAL CO.LTD.Adresse Incorporation Address Date Montreal.17 07 1934 Montreal.06 12 1941 Montreal.20 03 1936 Sherbrooke.11 12 1945 Montreal.20 04 1935 Montreal.11 06 1950 Montreal.05 11 1942 Montreal.09 12 1929 Québec.24 09 1937 Montreal.06 03 1937 Montreal.02 04 1946 Montreal.19 10 1946 Montreal.28 08 1934 Verdun.09 09 1940 Dorval.21 09 1942 Montreal.04 08 1934 Verdun.10 05 1941 Montreal.27 10 1949 Montreal.31 08 1964 Montreal.17 11 1948 Westmount.13 03 1946 Montreal.11 12 1945 Mount Royal.22 06 1949 Montreal.19 07 1945 Montreal.14 02 1933 Montreal.23 06 1947 Montreal.26 03 1935 Montreal.23 06 1930 Montréal.10 04 1946 Montreal.04 02 1949 Montreal.12 02 1935 Montreal.05 12 1944 Montreal.23 01 1947 Montreal.18 12 1941 Montreal.17 07 1942 Lachine.18 07 1944 3604 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.SO__ 57195-0 Le directeur du service dee compagnies, Pierre Desjardins.57195-o Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Adresse Incorporation Address Date Montreal.12 04 1920 Montreal.05 06 1946 Montreal.12 07 1933 Montreal.06 12 1938 Piedmont.06 03 1947 Montreal.25 10 1949 Montreal.09 01 1946 St-Dorothée.05 12 1938 Montreal.09 01 1950 Montreal.18 04 1940 Montreal.10 04 1942 Montreal.06 08 1942 Montreal.15 09 1928 Montreal.11 05 1942 Montreal.21 05 1941 Montreal.19 04 1944 Montreal.15 07 1943 Montreal.11 07 1950 Montreal.01 06 1938 Montreal.07 03 1949 Montreal.18 02 1947 Montreal.10 12 1946 Montreal.09 01 1950 Montreal.28 06 1950 Montreal.08 06 1949 Montreal.23 04 1938 Montreal.09 06 1942 Montreal.26 02 1946 Montreal.23 10 1942 Montréal.16 10 1945 Montreal.27 09 1940 Montreal.13 12 1945 Montreal.06 05 1949 Montreal.19 08 1943 Montreal.06 07 1929 Nom de la compagnie Name of (he company WINDSOR ASSOCIATION INC.WINDSOR MOTOR SALES.INCORPORATED.WINDSOR OIL LIMITED.WINDSOR SHOE & SLIPPER CO.WIN-SUM INN INC.WIPE-ON CORPORATION.GEORGE WISEMAN SONS LTD.WOLFE LUMBER MILLS CORP.WOMAN'S EXCHANGE OF MONTREAL INC.WONDERLAND CHILDREN'S WEAR LTD.WONDER-WOOD COMPANY LIMITED.WOODBURY CONSTRUCTION COMPANY.WOOD-CADILLAC MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) .WOODEN ACRES CAMPS INC.WOODEN ACRES INC.WOODLAND COMPANY LTD.WOODWORKERS LTD.WORLD APPLIANCES & TELEVISION CO.LTD.WORLD HIGH FIDELITY RECORDING INCORPORATED.WORLD TRADING IMPORT 4 EXPORT CORPORATION.YACHT CLUB LTD.YAFFY SYSTEMS INC.YARED'S LIMITED.YELIN'S OUTFITTERS LTD.YORK CREDIT LTD.YORK MINING SYNDICATE LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).YORK SHOE LIMITED.YOUNG SOPHISTICATE INC.YOUVILLE TRADING COMPANY LIMITED.YUCCAN CAFE LTEE.YVEL JERSEY MANUFACTURING LTD.ZAHLER INDUSTRIES CORPORATION.ZELL-EM (CANADA) LIMITED.ZEPHYR RADIO CORP.LTD.ZETLAND VICTORIA SQUARE GARAGE LIMITED. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3605 Révocation de dissolution Revocation of dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopé- The Minister of Financial Institutions, Companies and ratives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 6/ Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à section 5/ of the Companies Information Act.he deemed it propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les advisable to grant the petition of the interested parties made délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies Dissolution Gazette officielle No Name of the Companies Date Official GateUe No.ANNOR CORP.\t22\t12\t73\t51 ASSOCIATION DE C.à P.DE BAIE COMEAU HAUTERIVE INC.\tn\t02\t74\t6 BEVERLY INVESTMENT CORP.\toa\tKl\t73\t10 CLUB CABAN.\t29\t09\t73\t39 CLUB DES CINQ.\t18\t10\t73\t41 CLUB HAR-BOI.\t18\t10\t73\t41 CLUB KUE KUE INC.\t08\t11\t73\t44 CLUB LES COPAINS INC.\t24\t11\t78\t47 CLUB LIONEL INC.\t13\t10\t73\t41 CLUB DES MARAIS.\t28\t05\t73\t21 CLUB O-CAMP.\tm\t12\t73\t48 CLUB PANORAMA.\t24\t11\t73\t17 CLUB DE PECHE BEAU-SOLEIL.\t13\t10\t73\t41 CLUB WINDIGO INC.\t13\t10\t73\t41 D.L.F.INVESTMENTS LTD.\t16\t12\t73\t60 ELRAINE REALTY CORP.\t29\t12\t73\t52 LES ENTREPRISES ARMAND VADEBONCOEUR LTEE.\t09\t02\t74\te \t21\t11\t73\t47 \t13\t04\t74\t15 MERCHANTS' OVERSEAS CORPORATION.\tM\t01\t74\t4 LES PLACEMENTS NUCKLEINC.\t1)9\t02\t74\t\u2022 POFADEL INC.\t17\til\t73\t48 BAGOT MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).LES MINES BAGOT LTEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE)\t02\t02\t74\t6 SHANNOOSH FISH & GAME CLUB INC.\t24\t11\t78\t47 VAL MARTIN TV DISTRIBUTION INC.\t12\t01\t74\t2 YOUTHEATRE INC.\t17\t11\t74\tM en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution compagnies.of the said companies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir Consequently, the said companies are considered as having jamais été dissoutes en vertu de ladite loi.sans préjudice aux never been dissolved under the said Act, without prejudice droits acquis par toute personne entre la dissolution et la to the rights acquired by any person between the dissolution révocation._ and the revocation.Le directeur du service de* compagnie*, Pierre Desjardins.67195-0 Pierre Desjardinb.57195-0 Dirrctor of the Companie* Service. 3606 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Errata Lea noma de compagnie énoncéa ci-aprèa ont été inclua par erreur dans des avis de lettres patentes annulées dans la Gazette officielle du Québec, En effet, les compagnies concernées ont produit dans lea délais fixés les rapporta requia par le miniatre dana un avis antérieur.En conséquence, vu l'article 5d de la Loi des renseignements sur les compagnies, avis est donné que leadites compagniea n'ont pas été dissoutes par la publication desdits avia de dissolution.Errata The names of the companies, hereinafter mentioned have been included by mistake in notices of letters patent annulled published in the Québec Official Gazette.In fact, the companies concerned have produced, within the prescribed time limits, the reporta required by the Minister in a previous notice.Therefore, in compliance with aection 5d of the Companies Information Act, notice ia given that the aaid companies have not been dissolved by the publication of said notice of dissolution.\tDate de\tDate des \tconstitution\tlettres patentes Nom de la compagnie\t\tannulées Name of the Company\tDate of\tDate of \tIncorporation\tletters patent annulled LAROCQUE & GUAY INC.06 06 1969 23 03 1974 LES ENTREPRISES BONNEAU TEASDALE LTEE.29 01 1970 27 04 1974 CLUB PICHOU INC.05 02 1963 16 02 1974 THE LAURENTIAN LUMBER COMPANY.18 08 1900 16 02 1974 57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes (I™ partie)\tLetters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name\tIncorporation Siège social / Head Office Date ADMINISTRATION N.LANGLOIS INC.1367-7786 ANTIROUILLE DRUMMOND INC.13644044 AUTO MAURICE 8IMARD INC.MAURICE SIMARD AUTO INC.1365-9455 THE B.L.& R.MACHINERIES INC.LES MACHINERIES B.L.A R.INC.13569018 BAR SALON FRANCE INC.13678792 F.D.BEAULIEU INC.1367-8081 602, rue de la Vérendry, Boucherville.10 04 74 Drummondville.06 03 74 236, rue Lasalle, Arvida.23 04 74 Sainte-Croix.u oi 74 2462, Marie Viotorin, Varennes.23 04 74 686, rue Rochon, Saint-Laurent.17 04 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 1061 année, n° S0 3607 Nom / Name BOCAIR INC.13569596 J.P.BOSSE INCORPOREE.13545033 LA BOUTIQUE VANIER LTEE.13665065 CAN.WAY ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES CANWAY LTEE 1355-6717 CENTRE COMMERCIAL COTE DES NEIGES LTEE.PLA7.A COTE DES NEIGES LTD.13678263 CHAUSSURES BAMBI INC.13561783 CLUB DE GOLF MONT ST-HILAIRE INC.13677034 CONSTRUCTION GILLES D'ANJOU INC.13677316 CONSTRUCTION M.C.C.INC.1365-7061 J.4 R.DAIGLE, LTEE.13554084 PETER DALLA RIVA ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES PETER DALLA RIVA LTEE 1367-8222 DEUTSCH JEWELLERY LTD.BIJOUTERIE DEUTSCH LTEE 13552039 DISTRIBUTION BELLEVUE INC.13546643 LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE DESLAURIERS LTEE 1367-6473 LES ENTREPRISES KING INC.13552583 LES ENTREPRISES MACOU INC.1365-8721 ENTRETIEN J.G.INC.13678719 FLEURISTE GAETAN INC.GAETAN FLORIST INC.1354-9977 FORMACON CONCRETE PRODUCTS INC.LES PRODUITS DE CIMENT FORMACON INC.1367-1706 LES FOURRURES PRJME LIMITEE.PRIME PURS LIMITED 13563508 FRUITERIE DUMONT INCORPOREE.DU MONT FRUIT STORE INCORPORATED 13676689 G.R.CANADIAN JEAN MACHINE STORE INC.ENTREPOT CANADIEN DE JEANS G.R.INC 13676086 Incorporation Siège social / Head Office Date Montréal.21 11 73 Saint-Germain.07 03 74 228, avenue Bélanger, Vanier.03 04 74 4967 Lake Road, Dollard-des-Ormeaux 08 04 74 625, boulevard Dorchester ouest, 08 03 74 chambre 710, Montréal.3842, rue Ontario est.Montréal.21 03 74 280.Radisson, Mont-Saint-Hilaire.08 04 74 65, rue Châteauguay.Repentigny.08 04 74 Sainte-Catherine.01 02 74 Sainte-Hélène.29 03 74 Dollard-des-Ormeaux.17 04 74 260, boulevard d'Anjou, Châteauguay- 22 03 74 Centre.Thetford-Mines.11 03 74 Saint-Antoine-sur-Richelieu.04 04 74 Sherbrooke.17 01 74 284, rue Notre-Dame.SaintrPie.17 04 74 9, rang St-Claude, Saint-Philippe.08 03 74 Québec.19 03 74 52, rue Sacré-Coeur, Charlemagne.07 02 74 Montréal.28 03 74 8184, St-Hubert, Montréal.05 04 74 6881, Heywood Road, Côte-Saint-Luc 02 04 74 3608 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom / Name GAGNON & HARVEY INC.13555222 GATINEAU HILLS DEVELOPMENT CORPORATION.CORPORATION D'EXPLOITATION DES COLLINES DE LA GATINEAU 13552120 GROUPEMENT FORESTIER DE MASKINONGE, INC.13561634 LES IMMEUBLES AMPERE INC.AMPERE REALTIES INC.13674510 LES IMMEUBLES C.A.R.INC.13549035 LES IMPORTATIONS JACQUES ROGER INC.JACQUES ROGER IMPORTATIONS INC.1365-7186 RAYMOND Z.LEGAULT INC 1367-7968 LOCATION L.P.B.INC.13645181 MAÇONNERIE LE BOURLAY & BELANGER INC.13657954 MAISONS MAURIETT INC.1367-8265 MECANIQUE DE PRECISION RIVE-SUD INC.13676200 LES MEUBLES STYLBEC INC.13661196 MIRABEL KNITTING MILLS INC.LES USINES DE TISSAGE MIRABEL INC.13676671 MONTISCI FASHIONS INC.LES MODES MONTISCI INC.1367-7802 MONTREAL STEREO ELECTRONIC WAREHOUSE INC.ENTREPOT D'ELECTRONIQUE STEREO MONTREAL INC.1367-9635 LES PLACEMENTS BOLGO INC.1366-8374 POISSON SALE GASPESIEN LTEE.13643681 REPARATIONS DE BATTERIES ONTARIO INC.ONTARIO BATTERY SERVICE INC.1367-7762 RESTAURANT FRONTENAC INC.13658036 RESTAURANT LE PARRAIN INC.THE GODFATHER RESTAURANT INC.13673223 RESTAURANTS LE MARQUIS DE MONTCALM INC.1354\u20148987 8iège social / Head Office Incorporation Date Sept-Iles.1 Place Ville Marie, Suite 1608, Montreal.04 04 74 22 03 74 381.St-Jean, Saint-Edouard.21 02 74 Laval.2« 03 74 Québec.Montréal.15 03 74 .09 04 74 1430, des Alouettes, Sommet 16 02 74 Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville.1397.rue Savoie, Plessisville.07 04 74 11 04 74 Montréal.17 04 74 671, rue Marmier, Longueuil.03 04 74 26, rue Ste-Ursule, Québec.26 04 74 7756, 16e Avenue, Saint-Michel.06 04 74 1122, Desjardins sud, CP.20, Cap-Rouge.8000 Leonardo di Vinci Street, Saint-Michel.10 04 74 716 Taschereau Boulevard, Montreal 29 04 74 91, rue Comeau, app.9, Sept-Iles .16 04 74 Grande-Rivière.05 03 74 1176 est.rue Ontario, Montréal.10 04 74 Québec.11 04 74 Greenfield Park.21 03 74 2700, boulevard Laurier.Sainte-Foy .15 03 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3609 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date SALON DU DISQUE SEPT-ILES INC.1355-8358 SALON FUNERAIRE ST-AMAND & FILS LTEE.13552591 SERVICE DOMESTIQUE LAURENTIEN INC.1367-7455 SIWEL INC.13554100 SOCIETE DE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES S.O.T.I.INC.FABRICATORS OF INDUSTRIAL PIPING SYSTEMS S.O.T.I.INC.13561832 SOSTEQUA INC.13560347 TEROM INC.13561866 TONALCO LTD.TONALCO LTEE 1367-8230 ROGER VIENS.SPORT INC.SPORT, ROGER VIENS INC.13676921 ZEUS ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES ZEUS INC.13557749 700, avenue Laure, Scpt-Ilcs.16 04 74 281, rue Dupont, Sainte-Thècle.26 03 74 644, rue Wilfrid Martin, Saint-Jérôme 09 04 74 Montreal.29 03 74 Longueuil.02 05 74 6850, 4e Avenue est, Charlesbourg .25 04 74 900, 9e Avenue, Charny.22 03 74 Montreal.17 04 74 Sainte-Madeleine.01 04 74 4031 Hingston Avenue, Montreal____ 10 04 74 57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.67195-0 Pierre Desjardinb, Director cl the Companies Service.Lettres patentes (3\" partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act.he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head office Incorporation Date ASSOCIATION DES MARCHANDS DETAILLANTS DE PLACE QUEBEC PLACE QUEBEC RETAIL MERCHANT'S ASSOCIATION 13656469 CLUB DE L'AGE D'OR NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION.13556832 Québec.05 04 74 L'Assomption.08 04 74 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BAIE ST-PAUL INC 44, de la Lumière, Baie-Saint-Paul .01 03 74 13542352 CLUB 80CIAL ST-BENOIT.13566824 LA LIGUE DE TAXIS DE L'EST DE MONTREAL INC 13659646 8050, rue Notre-Dame est, Montréal.08 04 74 5310, rue Couture, Montréal 457.26 10 73 57196-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjabdins., 57195-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 3610 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol.106, No.SO Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Corail a accordé des lettres patentes supplémentaires à: panies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.8./ S.L.P.Date Date Modifications Changée LES ACIERS CANAM INC.16 08 CAN AM STEEL WORKS INC.13169-60 60 L'ASSOCIATION DU CENTRE DES 21 02 62 AFFAIRES DE SOREL 10910-62 ASSOCIATION DES COMMISSIONS 30 10 61 SCOLAIRES DU CENTRE DU QUEBEC INC.1483*-61 AUTOMOBILE CLAUDE PELLETIER INC.06 07 66 2657-66 BEAVCE AUTO ACCESSORIES LTD.08 03 56 BEAUCE AUTO ACCESSOIRES LTEE 10764-56 MAURICE BERUBE A FILS INC.23 11 66 4707-66 BISSELL & BISSELL ENTERPRISES INC.12 02 59 LE8 ENTREPRISES BISSELL A BISSELL INC.10738-59 BONNEX INC.20 03 66 10851-66 BROUILLETTE A LAHAIE LTEE.17 01 74 1354-4325 BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.13 02 62 QUEBEC TARIFF BUREAU INC.16185-51 CB%UEBEC)RINCBUILDINa SUPPLlBS 08 03 66 LA CIE CBS.BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (QUEBEC) INC 1170\u201465 CARREFOUR PONTIAC BUICK INC.22 08 67 3680-67 am-TO80 ENTREPRI8ES INC.25 05 70 07 03 74 Ancien nom / Former name: CANAM STEEL WORKS INC.29 03 74 Ancien nom / Former name: LES MARCHANDS UNIS DE SOREL INC.09 04 74 1) Ancien nom / Former name: L'ASSOCIATION DIOCESAINE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU DIOCESE DE NICOLET INC.2) Changeant le siège social / Changing the head office.3) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.21 03 74 Ancien nom / Former name: 8TATION DE SERVICE CLAUDE PELLETIER INC.03 01 74 1) modifiant le capital / Altering the capital.2) modifiant les privilèges et restrictions Modifying the powers.28 03 74 1) Ancien nom / Former name: BOULANGERIE MODELE INC 2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.22 03 74 1) Ancien nom / Former name: BISSELL A BISSELL REALTIE8 INC.2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.27 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.08 04 74 Etendant les pouvoirs /Extending the powers.08 04 74 Modifiant le capital / Altering the capital.28 03 74 Ancien nom / Former name: C.B.S.CASH A CARRY BUILDING 8UPPLIES INC.02 04 74 Ancien nom / Former name: FURLONG PONTIACBUICK INC.26 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital.2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Modifying the provisions of the letters patent. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3611 Nom I Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes ROSAIRE CHARBONNEAU INC.24 10 62 04 03 74 Ancien nom / Former name: 14185-62 LES HUILES DE TERREBONNE INC.CLUB DE GOLF KI-8-EB LIMITEE.07 06 23 22 04 74 1) Ancien nom / Former name: KIS-EB GOLF CLUB LIMITED Kl 8 EB COUNTRY CLUB LIMITED 872-23 2) Modifiant le capital I Altering the capital.3) Modifiant les dispositions des lettres patentes/ Amending the provisions of the letters patent.CONFECTION GUILMAR INC.22 11 51 29 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.GU1LMAR GAflMENT INC.14538-51 LA CORPORATION COMMUNICATIONS 17 06 62 03 06 74 1) Ancien nom /Former name: INTERSAT PIZZA PAN INTERNATIONAL INTERSAT COMMUNICATIONS CORPORATION.CORPORA TION 2) Etendant les pouvoirs / Extending the 12136-62 powers.COURTIER PROVINCIAL EN 13 12 71 06 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.ALIMENTATION (1971) INC.PROVINCIAL FOOD BROKER (1971) INC.716979 P.A.DARGIS INC.13 04 62 26 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.11571-62 REGENT DESJARDINS INC.14 07 66 07 12 73 Modifiant le capital / Altering the capital.2944-66 DISTRIBUTIONS MARCEL DION INC.13 08 70 11 03 74 Ancien nom / Former name: 3514-70 DIEL LEASING INC.GEORGE DIXON PROMOTIONS LTD.02 11 66 26 03 74 Etendant les pouvoirs / Extending the LES PROMOTIONS GEORGE DIXON powers.LTEE 4481-66 ELLENDALE MEDICAL BUILDING INC.29 02 60 07 11 73 Etendant les pouvoirs / Extending the 10875 power: EMCO FOODS LTD.16 12 70 28 03 74 Ancien nom / Former name: LES ALIMENTS EMCO LTEE EMCO MEAT PACKERS INC.6679-70 LES ENTREPRISES INOVCO INC.15 03 66 01 04 74 Ancien nom / Former name,- INOVCO ENTERPRISES INC.JEAN BOUDREAULT & FILS INC.1100-66 FORTIN AUTOMOBILES (AUTEUIL) INC.20 10 64 28 12 73 1) Etendant les pouvoirs / Entending the 4482-64 powers.2) Modifiant le capital / Altering the capital.FOYER CANADIEN (1974) LTEE.14 02 63 15 01 74 Ancien nom / Former name: 666-63 SOCIETE G.& O.LTEE FRANCO-DISQUE INC.15 07 63 28 02 74 Modifiant le capital / Altering the capital.3006-63 GENERAL GEAR INC.30 07 68 18 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital.3434-68 2) Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.3) Etendant les pouvoirs / Extending the powers.GREENSHIELD LTD.16 05 61 10 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital.12510-61 LE GROUPE DE COMPAGNIES JOSEPH 03 03 39 29 04 74 l)Ancien nom / Former name: INC.LOOMWEAVE CORPORATION.JOSEPH GROUP OF COMPANIES INC.2) Modifiant le capital / Altering the capital. 3612 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971, Vol 106, No.20 Incorporation L.P.8./ S.L.P.Modifications Nom / Name \u201e, Date Date Change» E.A.HART A COMPANY INC.06 06 58 09 01 74 Ufg^g^g/ JEWELLERY MANUFACTURING CO.2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letter) patent.WALTER KIDDE A COMPANY OF 16 04 28 04 04 74 Modifiant le capital / Altering the capital.CANADA, LIMITED 616-28 LANVAL INC.18 01 63 22 03 74 Ancien nom / Former name: 15169-62 LANVAL TRICOTS LTEE.ANDRE LEPINE SERVICE STATION INC.28 04 72 28 11 73 Modifiant le capital / Altering the capital.722192 LIGUE DE BASEBALL AMATEUR DE 23 07 53 19 03 74 Ancien nom / Former name: CHAMBLY INC.LES LOISIRS FORT CHAMBLY CHAMBLY AMATEUR BASEBALL INC.LEAGUE INC.16227-53 LYNDALE DEVELOPMENT LTD.01 02 73 27 02 74 Modifiant le capital / Altering the capital.AMENAGEMENT LYNDALE LTEE 73-6262 MADORAY INC.17 03 72 01 04 74 Modifiant le capital / Altering the capital.72-1523 MARCHE AUX PUCES DE STASH LTEE .24 11 69 09 04 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the STASH'S FLEA MARKET LTD.power).5823-1969 METROPOLITAN TIRES INC.08 11 66 22 10 73 Ancien nom / Former name: PNEUS METROPOLITAINS INC.METROPOLITAN TIRE 4914-65 RETREADERS CORP.NUREMBERG TABLE WARE INC.09 02 73 22 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.LES ARTICLES DE TABLE NUREMBERG INC.736326 °^ALETmSUMOBnjÉrtES ONYX LTEE\" * * 2' °3 W Modifiant le capital / A«ennoeopOol.724162 PLACEMENTS RAYMOND GUY INC.21 06 68 22 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital.2908-68 2) Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.^&,PkACEMENTS PAUL ST-ONGE INC.22 05 53 04 01 74 1) Ancien nom / Former name: 10831-53 PAUL ST-ONGE INC.2) Etendant lee pouvoirs / Extending the powers.P0LLTEEN1QUE MEDICALE CONCORDE 24 06 72 04 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital.722878 6219-A67,RENT POUUOT AUT° INC15 12 67 22 03 74 E«*°°«'t !«¦ Pouvoirs/Extending the power.PR9DUIT8 DE PAPIER .PARAMOUNT » 24 09 71 17 01 74 Ancien nom / Former name: ^PARAMOUNT PAPER PRODUCTS LTD.PARAMOUNT pAPER PRODUCTS LES PROMOTIONS V.L.INC.26 07 73 27 03 74 Ancien nom / Former name: LA CIGARETTE LA QUEBECOISE INC GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3613 Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom,' Name Date Date Changée RESTAURANT DELICES BAR-B INC.BAR-B DELIGHT RESTAURANT INC.738031\t31\tOS\t73\t19\t02\t74\tModifiant certaines dispositions des lettres patetnes / Amending certain provisions of the Utters patent.RESTAURANT LA RAPIERE INC.176-69\t10\t01\t69\t24\t04\t74\tAncien nom / Former name: LE RESTAURANT « EL BARRIO LATINO \u2022 INC.RUBY-LOU INC.723866\t07\t07\t72\t08\t03\t74\tModifiant le capital / Altering Oie capital.SANAIR MANAGEMENT LTD.716822\t09\t12\t71\t04\t04\t74\tEtendant les pouvoirs / Extending the powers SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DE L'EST DU QUEBEC LTEE 716293\t05\t10\t71\t30\t04\t74\tModifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DE L'EST DU QUEBEC LTEE 715293\t05\t10\t71\t30\t04\t74\tModifiant le capital / Altering the capital 8PLICED VENEERS SPECIALTIES INC 4176-66\t17\t10\t66\t11\t02\t74\tModifiant le capital / Altering the capital.TRANSPORT ARMAND ALLAIRE LTEE .722-71\t30\t03\t71\t19\t03\t74\tAncien nom / Former name: TRAN8PORT ARGIL LIMITEE Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.67195-0 Pierre Desjardins.67195-0 Director of the Companies Service.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of;\t\t\t\t\t Nom / Arame\tIncorporation Date\t\t\tDissolution Date\t\t DOUG ALEXANDER & SON INC.5002-66\t.18\t01\t67\t17\t06\t74 LES AMATEURS DU SPORT DE STE-AGATHE DES MONTS INC.14 715457\t\t10\t71\t17\t05\t74 AMEUBLEMENT PLATEAU LTEE.PLATEAU FURNITURE LTD.765-65\t.18\t02\t65\t24\t06\t74 J.-EDMOND BERIAULT INC.4847-67\t.22\t11\t67\t24\t05\t74 BICKERDIKE INVESTMENTS LIMITED.487-37\t.19\t02\t37\t24\t05\t74 LE COLLEGE MONT-8AINT-LOUIS.12523-54\t.26\t10\t54\t24\t06\t74 DEXTER MOTORS LTD.6079-47\t.30\t07\t47\t17\t06\t74 ECOLE SECONDAIRE ASSELIN INCORPOREE.11090-61\t.14\t07\t61\t17\t06\t74 3614 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Incorporation Date Dissolution Date 27 06 61 29 07 36 11 06 63 12 08 66 29 10 65 14 07 64 04 11 67 02 04 68 30 05 66 03 10 60 07 06 63 31 10 60 12 07 65 02 04 64 12 03 69 24 12 71 05 02 59 26 10 54 01 05 68 17 06 36 03 03 71 17 08 64 24 07 62 17 05 74 24 05 74 24 06 74 17 06 74 24 05 74 17 05 74 17 05 74 17 06 74 29 06 74 17 06 74 24 06 74 17 05 74 24 05 74 17 06 74 24 06 74 17 05 74 17 05 74 17 05 74 17 06 74 29 05 74 17 05 74 17 05 74 17 05 74 Nom / Name ECOLE SECONDAIRE MONT-SAINT-LOUIS.12792-61 EDGEHILL COMPANY LIMITED.1690-36 FLANDERS EQUITIES LTD.2551-63 GARAGE ROGER BERTRAND INC.3568-65 GEMINI HOLDINGS LTD.4774-65 HOTEL LACHUTE LIMITEE.LACHUTB HOTEL LIMITED 2801-64 JULIEN A FRERE INC.13423-57 MARCEL LAPOINTE, INC.1543-68 LEV ANA CORP.11767-66 MACGREGOR-COMARAIN (CANADA) LTEE.MACGREGOR-COM ARAIN (CANADA) LTD.13412-60 METROPOLITAN POULTRY INC.2507-63 THE NORTHERN GASPE PULPWOOD CO.7694-50 NORTHLAND AIRWAYS LIMITED.3167-65 PEDOGRA LTEE.PEDOGRA LTD.1099-64 LE REFLET DE BEDFORD INC.506-69 RESTAURANT ETOILE BLEUE LTEE.717313 ROCKLYNN REALTIES CORP.10662-69 ALCIDE ROUSSEAU INC.12490-64 .SOCIETE DE FINANCE MARK V INC.1988-68 .SUBURBAN THEATRES, LTD.1426-36 .LES SYSTEMES DJS COMPACTAGE DE REBUTS DU QUEBEC INC QUEBEC WASTE COMPACTER SYSTEMS INC.872-71 TELIN LTD.3660-64 .A.O.TERRIAULT INC.12714-62 . GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° SO 3615 Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date TOPPS WOMEN'S WEAR INC.1012-38 VENDER SALES AND SERVICE LIMITED.11906-55 VERSAILLES INVESTMENTS INC.11339-55 VICTORIA HOLDINGS LTD.16383-59 VIVA KNITTING MILLS LIMITED.3363-70 09 06 38 13 07 55 13 06 56 24 11 69 03 08 70 17 06 74 17 05 74 17 05 74 17 05 74 17 06 74 57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjabdins.57195-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Domicile légal (Art.30) Legal domicile (Art.30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose names follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Domicile légal Legal domicile Date Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address A.O.8.METAL INC.2430-69 ADART LTD.717094 AIR ALMA INC.16890-59 ALLO SERVICE LTEE.HELLO SERVICE LTD.12636-58 ALPINA CORP.10692-69 AMEDYA ENTERPRISES LTD.1016-71 ARCA FURNITURE INC____ 198-66 ARVIDA DECORATION INC.6992-69 ASSOCIATION DE HOCKEY ST-HENRI INC.4016-70 L'ASSOCIATION DES CITES ET VILLES DU DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS.THE ST.FRANCIS DISTRICT CITIES AND TOWNS ASSOCIATION.3066-63 20 05 69 133.rue Chapleau, Terre- 61, rue Saint-Joseph, bonne.Terrebonne.22 12 71 1255 University Street.1374 Sherbrooke 8treet Suite 1701.Montreal.West, 8uite 10A, Mont- real.23 12 59 336, rue Scott, Aima.693, rue Sacré-Coeur est.Aima.22 10 68 Québec.463, rue St-Jean, Québec.09 02 59 Montréal.606, rue Cal heart, bureau 440, Edifice Canada Cément Company, Montréal.26 02 71 160 King Street, Suite 101, 416 Beverly Avenue, Montreal.Montreal.17 01 66 4069.boulevard St-Lau- 4117, boulevard St-Lau-rent, Montréal.rent, Montréal.06 01 70 Arvida.641, rue Dubose, Arvida.09 09 70 Montréal.976, rue Agnès, Montréal.29 07 63 Richmond.160, rue Child, Coaticook. 3616 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Ltnal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ASSOCIATION DES CITOYENS DE LAPRAI- 11 II 60 Laparirie.1965, rue La Bataille RIE INC nord, Lapraine.16165-60 L'ASSOCIATION DES DAMES SEULES DE 09 06 69 180, rue St-Jacques, Sainte 218, rue Jacques-Cartier, ST-JEAN.Jean.Saint-Jean, 2754-69 L'ASSOCIATION DES EMPLOYES CIVILS.18 06 38 980.est Grande-Allée.650.rue Laurier, Québec.1371-38 Québec.ASSOCIATION DES GYMNASTES THERA- 16 10 70 241, 5e Rue, Québec.310.Place Neuviale.Qué- PEUTIQUES DU QUEBEC.bec.4527-70 ASSOCIATION MEDI-TECHSCIENCE.20 08 69 6767, rue Decelles, Mont- Place Bonaventure.Etage 4063-69 réal.E.17 Elysée, Montréal.ATLIFIC INNS INC.06 11 64 612, rue St-Jacques ouest, 630, rue Sherbrooke ouest, 4962-64 Montréal.Montréal.AUBIN REFRIGERATION INC.02 04 69 815, rue des Plaines.1235, rue Ste-Julie, Trois- 1637-69 Trois-Rivières.Rivières.AVIATION HOLDINGS LIMITED.12 12 67 6, Place Ville Marie, suite 4, Place Ville Marie, suite 6147-67 445.Montréal.612.Montreal.B.I.C.(T.M.) INC.04 03 71 91, rue Mailhot, Thetford Route rurale numéro 3, 1043-71 Mines.Thetford Mines.ARMAND BAILLARGEON LTEE.01 08 72 Saint-Georges-Ouest.1300, 7e Avenue, Saint- 4273-72 Georges-Ouest.W.H.BEATON INC.22 04 69 Montreal.Twelfth Floor.1134 St.1948-69 Catherine Street West.Montreal.BEAUTY SEAL QUEBEC INC.28 06 66 1640.rue Sherbrooke ouest.1573.rue Beaubien est, 2686-66 Montreal.Montréal.LA BELLE RELIURE DE MONTREAL INC.02 11 70 8120, boulevard Viau, 8377, boulevard Lange- 4777-70 Montréal.lier, Montréal.BENEFIT SERVICES INCORPORATED.08 03 67 666, rue Sherbrooke ouest, 626, boulevard Dorchester 10824-67 Montréal.ouest.Montréal.;Î0.5I'LBESHARA INC.16 07 66 233, rue Laval.Laval.185.rue Brien, Laval.2875-66 B,y9UTERIE PHANEUF LTEE.13 02 70 Montréal-Nord.10533.rue Pie IX.Mont- 619-70 réal-Nord.?imÏMPRE REALTIES inc.09 10 58 414, rue St-Jacques ouest, 1662, boulevard de Mai-ut»»-68 Montréal.sonneuve ouest, Montréal.BLAND, LEMOYNE, SHINE 4 VICTOR PRU8 12 03 70 1936 ouest, rue Maison- 1420 ouest, rue Sherbrooke, 1106-70 neuve, Montréal.Montréal.GASTON BOURASSA.LTEE.28 12 49 Trois-Rivières.600.rue Albert Durand.*\"\"'\"*¦ Trois-Rivières.79ak«b?utique JANU8 LTEE23 10 72 Centre d'Achat St-Loui« 3318.nie Perigny.Sainte 725824 de France, Chemin 8t- Foy.Louis, Sainte-Foy.Bo^°rHoTON CONSTRUCTION INC.12 06 69 Bromptonville.1100.rue Ontario, Sher- 1271°-69 brooke.KSS?^ DEVELOPMENT CORP.15 01 59 9720, rue Jeanne-Mance.4946.rue Montclair 10215-59 Montréal.Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 197A, 106' année, n° SO 3617 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie -;-\u2014 Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address CABBAGE WILLOWS CLUB INC.04 10 71 Edifice Sun Life, Mont- 3, Place Ville Marie suite CLUB CABBAGE WILLOWS INC.real.312, Montréal.716165 CANADA BROOM SUPPLY CO.LTD.28 06 65 2110 Bennett Street, 2200 Bennett Street.11636-65 Montreal.Montreal.CAPOBIANCO INSURANCE INC.15 10 63 Montréal.6821, St-Denis, Montréal.ASSURANCE CAPOBIANCO INC.4267-63 CARON PLASTIC VACUUM FORMING INC.23 01 73 614 oueet, rue St-Jacques, 6633, rue Jeanne-Mance, LES FORMATIONS DE PLASTIQUE A VIDE suite 202, Montréal.Montréal.CARON INC.729703 CASDO INC.20 12 71 600, rue Dorchester ouest, 135, Place Côte Vertu app.717224 Montréal.307, Montréal.LE CENTRE DE BENEVOLAT DE LA 13 07 72 1510, 5e Avenue.Shawi- 850, 6e Avenue, Shawini- REGION DE SHAWINIGAN.nigan-Sud.gan-Sud.723946 CENTRE DE L'AUTO JACQUES ET BER- 26 11 71 Levis.79A, route Kennedy.Levis.NARD JALBERT INC.716486 CENTRE DE RESTAURATION COTE ST-LUC 15 08 72 4104, rue Sherbrooke ouest.4101.rue Sherbrooke ouest.INC.Westmount.Westmount.724541 CENTRE LACORDAIRE, REGION DU LAC- 05 11 67 Lac-Mégantic.3760, rue Laviolette, Lac- M EG ANTIC.Mégantic.13376-67 CENTRE LOISIRS DE L'AGE D'OR DE ROUYN 11 04 68 53, Perreault eBt, Rouyn.210 rue Mercier, Rouyn.2723-67 LE CENTRE ROUTIER INC.01 12 67 8, rue Hôtel de Ville, 375, rue Témiscouata, 4998-67 Rivière-du-Loup.Rivière-du-Loup.EUG.CHALIFOUR.INC.07 03 53 1601, Côte Gignac, Sillery.1682, chemin St-Louis, 4737-53 Sillery.CHARLTON TRANSPORT (QUEBEC) LIMITED 19 12 55 Québec.500, Grande-Allée est, 13553-56 suite 609, Québec.CLUB DE L'AGE D'OR DE NOTRE-DAME DE 26 03 73 353, rue Notre-Dame, 300, rue Ste-Ursule, Jon- JONQUIERE.Jonquière.quière.731361 CLUB DES LIONS DU QUEBEC METROPO- 01 04 60 1363, 3e Avenue, Québec 1550.rue Dorchester nord.LITAIN.Québec.16309-69 CLUB LA RUCHE INC.21 06 66 878, rue St-Augustin, Que- 1520.rue Semple, Québec.2645-66 bec.CLUB LES MONTAGNAIS INC.08 05 69 45, rue Salaberry, Baie- 71.rue Alfred Poulin, 1786-69 Comeau.Baie-Comeau.LE CLUB SOCIAL DE LA LOGE 2230 DOL- 11 02 70 Miatassini.Avenue des Chutes, Mis- BEAU-MISTA8SINI INC.tassini.670-70 CLUB SOCIAL MAC-ALMA INC.18 04 70 Aima.801, Chemin Pont de 1693-70 Taché Nord.Arvida.COLLEGE DU LAC ST-JEAN INC.16 02 70 Aima.480, rue Champagnat sud, 768-70 Aima. 3618 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address COMMERÇANT DE BOIS G.T.LTEE.12 974-71 COMMUNICOM INC.26 3069-69 COMPAGNIE D'ADMINISTRATION & DE 16 GESTION C.A.G.INC 1313-71 COMPAGNIE DE TEXTILE BRIDGEMAN 29 LTEE.BRIDGEMAN TEXTILE COMPANY LTD.746255 CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS RICHE- 10 LIEU-YAMASKA INC.13746-56 CONSTRUCTION J.R.L.LTEE.07 11286-61 CONSTRUCTION LEGATEC INC.16 LEGATEC CONSTRUCTION INC.733173 CONSTRUCTION MARIEVILLE INC.29 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.6916-64 LES CONSTRUCTIONS HARVEY (CHIBOU- 07 GAMAU)TNC.723829 CORO SHOE FINDINGS LTD.20 10953-67 CORPORATION UNIVERSELLE DE PLANI- 04 FICATION FINANCIERE.UNIVERSAL CORPORATION OF FINANCIAL PLANNING.10576-59 CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES 29 (DIVISION DE QUEBEC).12761-56 CREDIT DU LAC INC.18 12984-62 DASSE ENTERPRISES CORPORATION.13 CORPORATION DES ENTREPRISES DASSE.1870-71 DEL.VIN PLUMBING 4 HEATING INC.18 LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE DELVIN INC.3874-63 DEMENAGEMENT PARADIS LTEE.31 192-36 DESBIENS & MERCIER INC.04 720133 DEVELOPPEMENT LAC-MEGANTIC INC.30 13676-60 DION CONSTRUCTION LTEE.06 2946-63 03 71 Rimouski.362.nie Louis-Bertrand, Rimouski.06 69 361.Place Royale.Mont- 276.ouest rue Saint-Jac- réal.ques, Montréal.03 71 140 ouest, rue St-Germain, 138-A ouest, rue St-Ger-Rimouski.main, Rimouski.01 74 Montréal.417, rue St-Peter, Montréal.12 66 Saint-Hyacitnhe.1871, rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe.03 61 405, rue St-Germain, 323, rue Taché-Est.Ri- Rimouski.mouski, 07 73 8ainte-Foy.990, avenue de Bourgogne.Sainte-Foy.12 64 305.rue Huot.Marie-ville.07 72 582, 2e Rue, Chibougamau.2010, rue Dupont, Marie-ville.987, rue Moiaan, Chibougamau.03 67 Montreal.4878, rue Henri Julien, Montréal.02 59 Montréal.Edifice de la Bourse suite 3312, Carré Victoria, Montréal.10 55 Québec.580, Grande-Allée est, Québec.07 62 110, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien.04 71 5395 Queen Mary Road, Montreal.09 63 323, rue Duluth est, Montréal.1120, boulebard Sacré-Coeur, Saint-Félioien.6268 Notre-Dame 8treet, West, Montreal.844, boulevard Henri-Bourassa est, Montréal.01 36 Québec.1245, des Artisans, Québec.01 72 Chicoutimi.393, rue Racine, Chicou- timi.08 60 77.rue Frontenac, Lac- 6292.rue Frontenac.Lac-Mégantic.Mégantic.07 63 Les Saules.1675.Carré Ader, app.2.Les Saules. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3619 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address LES DISQUES S.E.X.INC.02 03 70 20, Marsolais, Outremont.550, Wiseman.Outremont.S.E.X.RECORDS INC.927-70 LES DISQUES SOLUTIONS LTEE.29 10 71 8483, rue Clark, Montréal.166.rue St-Amable, Mont- 715788 real.LES DISTRIBUTIONS GILBERT LTEE.10 03 70 719, rue Murdoch, Chicou- 393, rue Racine, Chicou- 1023-70 tirai.timi.LE DOMAINE DU BON TEMPS.04 07 66 Roberval.400, rue Bergeron, Rober- 2140-66 val.DUFCO INC.01 06 72 8B, rue St-Jean-Baptiste, 1140.rue St-Jean-Baptiste, 723070 Saint-Félicien.Saint-Félicien.DUFORT A LAVIGNE LTEE.29 08 62 Montréal.1227, Parc Lafontaine, 13514-62 Montréal.E.J.A.HOLDINGS LTD.11 03 64 4630 Clark Street.Mont- 800 Victoria Square, 1167-64 real.Montreal.EASTERN CLAIMS ADJUSTERS (TROIS- 13 07 65 Québec.680.Grande-Allée est, RIVIERES) LTD.Québec.AGENT8 DE RECLAMATIONS DE L'EST (TROIS-RIVIERES) LTEE.3262-65 EASTERN EXPRESS LTD.27 08 70 Anjou.10101, boulevard Park- 3719-70 way, Anjou.EDIFICE BOIS DE COULONGE INC.02 04 71 Québec.2, Place Québec, suite 636, 1892-71 Québec.LES EDITIONS DE LA TABLE RONDE INC.29 03 67 1010 ouest, rue Ste-Cathe- 351, Place Royale, Mont- 1351-67 rine, Montréal.réal.ELECTRI-TEST INC.28 08 67 Montréal.1302, rue Fleury est.3459-67 Montréal.ENTREPRISES ALPHASER INC____.16 07 69 10690, Jeanne-Mance, 111.Fleury ouest, Mont- 3389-69 Montréal.réal.ENTREPRISES DANIEL RAYMOND LTEE.28 01 65 221, rue Labrie, Laval-des- 274, rue Brien, Laval-des- 398-65 Rapides.Rapides.LES ENTREPRISES FORESTIERES DU LAC 07 03 72 209, rue Gauthier ouest, 556, rue Gauthier ouest, 8T-JEAN INC.Aima.Aima.721283 LES ENTREPRISES LOIRE LIMITEE.09 07 70 Sherbrooke.1376, rue Borlase.Sher- 3007-70 brooke.LES EXTINCTEUR8 DRUMMOND INC.29 03 72 624, rue Garceau, Drum- 28, rue .Holmes, Drum- 721681 mondville.mondville.FAMOUS KOSHER PRODUCTS (CANADA) 29 01 65 Montréal.230, avenue Fairmount LTD ouest, Montréal.429-65 FASHION SILKS de DRAPERIES INC.11 12 68 7790 Sherbrooke Street 7403 St.Hubert Street, 80IERIES A DRAPERIES A LA MODE INC.East, Montreal.Montreal.6396-68 FINANCE CENTICO LTEE.22 01 70 Montréal.676.rue Henri Bourassa CENTICO FINANCE LTD.est, Montréal.308-70 FIRST DORVAL LIMITED.27 06 63 Dorval.280.Dorval, Dorval.2121-63 3620 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address FLEjUR DE LYS JEWELLERY MFG.LTD.2458-70 FONTENAY INC.1081-65 J.E.FORGET MEUBLES INC.,.J.E.FORGET FURNITURE INC.1999-66 FRANCE-DEL MODES INC.6950-64 03 06 70 2500 Bates Road, Montreal.10 03 65 105, Côte de la Montagne, Québec.18 05 66 Montréal.G.C.G.LTEE.3399-67 GAGNE, B ANTE Y ET CIE.5624-70 LES GALERIES ST JEAN INC.10551-62 GARAGE BRIEN LIMITEE 11960-62 GESTION G.L.LTEE.3584-69 GINETTE SPORTSWEAR INC.2887-69 GLOSAL MERCHANDISERS LTD.6005-64 GRAHAM CREATIVE SALES INC.4919-70 GREEN COAST RESOURCES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).10272-58 BERTHOLD GROLEAU & ASSOCIES LTEE____ 2960-69 HAMEL, MALOUIN.RUEL ET ASSOCIES LTEE 716205 LES IMMEUBLES BEAUMAR INC BEAU MAR REALTIES INC 13772-60 LES IMMEUBLES CANABEC INC.714180 LES IMMEUBLES CHELNIC INC.3113-70 LES IMMEUBLES DES NEIGES INC 6896-69 IMPRIMERIE IDEALE INC 1339-70 INDEPENDENT ELEVATOR MAINTENANCE CJORP.3816-70 LES INDUSTRIES DE JOUETS ROLO INC.ROLO TOY INDUSTRIES INC.736364 30 12 09 08 22 01 05 02 04 05 31 07 13 06 30 12 30 12 04 02 13 06 16 11 27 03 09 08 16 07 10 12 21 04 02 09 64 Montréal.67 1063, rue St-Jean, Québec.71 3216, rue Lacombe, Montréal.62 580, Grande-Allée est, Québec.62 5873, rue des Ecores, Montréal.69 Trois-Rivières.69 Montréal.64 Montréal.70 439.rue McGill, Mont- réal.58 Suite 904, 1155 Dorchester Boulevard West, Montreal.69 2015, rue de la Montagne, Montréal.71 1430, boulevard Lemire, Drummondville.61 1887, rue Mont-Royal est, Montréal.71 Québec.70 676, rue Nolin, Aima.69 Chicoutimi.70 Lauzon.70 Montreal.14 02 73 1464, rue de la Montagne, Montreal.460 St.Catherine Street West, Montreal.915, avenue Casot, Québec.2322, rue Bélanger est, Montréal.2175 Crescent, Montréal.2éV.rue St-Stanislas, Québec.2015, rue Peel, bureau 265.Montréal.1100, rue St-Jean, Québec 5377, rue de Lorimi, Montréal.1645.de Longueuil, Trois-Rivières.5505.rue St-Laurent, bureau 4214, Montréal 8926, boulevard St-Laurent, Montréal.485.rue McGill, Montréal.Suite 703, 612 St.James Street, Montreal.1055, rue Beaver Hall Hill, Montréal.150, rue Marchand, Drummondville.1889, rue Mont>Royal est.Montréal.100, Place d'Youville, Québec.522, rue Collard, Aima.610, rue Bécard.Chicoutimi.105, de la rue St-Joseph, Lauzon.404, St.Henri Street, Montreal.3637, boulevard Métropolitain est, suite 1601, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° 20 3621 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address INFORMATRJX 2000 INC.23 02 70 180, rue Ontario, Sher- 166, rue Wellington Nord, 679-70 brooke.suite 117, Sherbrooke.JACQUKL INC.18 09 67 Québec.1990, 23e rue, Québec.3959-67 KABUR-KOSTINER INC.19 02 69 Montréal.4398, boulevard St-Lau- 781-69 rent, Montréal.KEBEC CONTROL INC.23 04 71 4442.rue Adam, Mont- 6684, rue Laurendeau, 2165-71 réal.Montréal.K1NG-MEUNIER ASSOCIATES INC.02 02 70 353.St-Nicholas, Mont- 11744, boulevard O'Brien, KING-MEUNIER ASSOCIES INC.réal.suite 213.Montréal.212-70 L.E.M.ELECTRIQUE LTEE.25 06 69 Montréal.9390, rue Charles de 2827-69 Latour, Mbntréal.LES LABORATOIRES OUTAOUAIS INC.-26 08 70 43, rue Langevin, Hull____ 40, rue Adrien-Robert, 3652-70 Hull.LAURIER BEDDING INC.28 08 67 6844, boulevard St-Laurent, 8750, rue Verville, Mont- 12256-57 Montréal.réal.LAURIER MORTGAGE CORPORATION.02 02 65 60 Place Crémazie, Mont- 1440 Towers, Suite 100.LA CORPORATION D'HYPOTHEQUES real.Montreal.LAURIER.660-65 LAVERS LIMITED.20 02 63 Montreal.6149 Marquette Street, 816-63 Montreal.LIGUE RURALE ALBERT GAUCHER INC____ 18 07 66 1135, de l'Evéque, Trois- 564, rye Ste-Julie, Trois- 2521-66 Rivières.Rivières.LOIGNON, DURAND & QUEVILLON INC.06 02 68 602, boulevard Terrebonne, 744, rue Corbeil, Terre- 479-68 Terrebonne.bonne.LONDON INVESTMENTS LTD.08 01 65 4459, rue Marquette, 3620, rue St-Zotique est.LES PLACEMENTS LONDON LTEE Montréal.Montréal.4794-64 LURA CORPORATION LTD (NO PERSONAL 19 12 55 216 St.James Street West, 621 Craig Street West.LIABILITY) Room 301, Montreal.Suite 400, Montreal.13491-56 M.A.C.H.LTEE.02 01 70 4744, Adam, Montreal____ 3451, rue d'Orléans, 5837-69 Montréal.MAGMA FILM STUDIOS INC.09 12 68 3213, rue Ste-Catherine 3214, rue Rouville, 5511-68 est.Montréal.Montréal.LA MAISON PAINCHAUD.13 09 67 30.chemin Ste-Foy, 965, rue Richelieu, Québec 3854-67 Québec.MAISONNEUVE MANAGEMENT 06 06 67 Ville Saint-Laurent.2035, rue Thimens, Saint- CORPORATION Laurent.LA CORPORATION D'ADMINISTRATION MAISONNEUVE 2248-67 MARTHE CHILDREN'S WEAR MFG.LTD____ 11 03 65 Montréal.10, rue Ontario ouest.1115-66 Montréal.ALEX MCDONALD ET ASSOCIES LIMITEE .17 02 70 768, boulevard 8t-Cyrille 8, Côte de la Fabrique, 747^70 ouest, Québec.(2e étage), Québec.McDONALD RAILWAY SUPPLIES LTD.30 12 60 4852 Westmore Avenue, 2185 Madison Avenue, 10035-61 Montreal.Montreal. 3622 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May IS, 1971, Vol.106, No.SO Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address PAUL MEALY INC .16 06 69 Saint-Hyacinthe.2430, rue Notre-Dame, 2941-69 Saint-Hyacinthe.MUA CORPORATION.22 12 60 1 Place Ville Marie.769.carré Victoria.15773-60 Montréal.Montréal.LES MINES DE FER VAUQUELIN LTEE 28 06 62 Montréal.200, rue St-Jacques ouest, (LIBRE DE RESPONSABILITE Montréal.PERSONNELLE) VAUQUELIN IRON MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) 12170-62 MONTREAL SCREW MACHINE PRODUCTS 26 01 62 976.rue Amherst.9170.Charles de la Tour.LTD.Montréal.Montréal.10330-62 LES MONUMENTS BOUCHER ET LEFEBVRE 18 01 74 Cap-de-la-Madeleine.275.Dessureault, Cap-de- INC la-Madeleine.740240 EMILE MORISSETTE LTEE.16 12 66 La Tuque.369, rue St-François, La 6219-66 Tuque.MOULDING PRODUCT8 LTD.28 12 61 Montreal.1406 Seaver Street, 16241-61 Montreal.NAERKS HOLDINGS LTD.02 04 74 Montréal.800, Place Victoria, LES GESTIONS NAERK LTEE chambre 2401.Montréal.1367-6176 NETTOYEURS NET-TOP CLEANERS INC.18 04 61 Sillery.2000, rue St-Michel, 4466-51 Sillery.NEW INSCO MINES LTD.(NO PERSONAL 14 12 38 800 Victoria Square.500 Place d'Armes, Suite LIABILITY) Suite 720.Montreal.1200.Montreal.2676-38 PARADIS.ST-PIERRE A ASSOCIES LTEE .20 06 69 Montréal.675, rue Henri Bourassa 2956-69 est, Montréal.LOUIS PHILIPPE CONSTRUCTION INC.23 10 69 12, rue Isabelle, Hull.24, rue Décoase, Hull.4735-69 PIABLO INC.26 01 65 80, rue St-Pierre, Québec .71, rue St-Pierre: Québec 377-65 PIZZA PAN INTERNATIONAL CORPORATION 17 05 62 1449, rue St-Alexandre.606.rue Cathcart.suite 12136-62 Montréal.405.Montréal.LA ivr-CE DU TAPIS «DRUMMONDVILLE) 22 07 64 618, boulevard Lemire, 1411, boulevard Lemire.INC.Drummondville.Drummondville.2949\u201464 P,LoACEMENT8 BCH- INC.02 08 67 7003.rue Christophe- 4613, avenue d'Orléan, 3184-67 Colomb, Montréal.Montréal.LCOLLi£E/vK 06 07 66 162 \",e Notre-Dame est.611.Place d'Armes, m^-SO INVESTMENTS INC.Montréal.Montréal.i'oEHi'ACEMENT8 COUPEY INC.24 12 64 Montréal.4058, Oxford.Montréal.um£EMENTS FINCO LTEE.23 09 64 1116 ouest, rue Laurier.48.Farnham.Montréal iMUi-bt Montréal.Case Postale 1136.Place Bonaventure, Montréal.h'rS/£ACEMENT8 LONGCHAMP.01 10 62 210 est, boulevard Charest, 770.Ire avenue.Québec.14U04-6J Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971, 106' année, n° SO 3623 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address LES PLACEMENTS MODELES INC.13434-55 LES PLACEMENTS TAUPE INC.1693-69 LES PLACEMENTS VELANO INC.717211 PLURAM (SOCIETE PLURI-DISCIPLINAIRE DE PLANIFICATION, D'URBANISME ET D'AMENAGEMENT) INC.4382-70 30 12 55 Montréal.10 06 69 Montréal.22 12 71 Lévis.PRADESINC.4559-65 PREMIER WIRE & METAL PRODUCTS LTD.1039-65 LES PRODUCTIONS GAROU INC.3038-69 PRODUCTIONS JEAN, MICHELE INC.722-70 LES PRODUCTIONS POP INC.6261-69 LES PRODUCTIONS PRISMA INC.PRISMA PRODUCTIONS INC.2251-70 PROSER INCORPOREE.PROSER INCORPORATED 1585-71 PROU CONSTRUCTION INC.10380-55 RENE PROULX & ASSOCIES INC.2733-63 PROVINCIAL AIR DUCTS CLEANERS INC.NETTOYEUR PROVINCIAL DE CONDUITS D'AIR INC.5368-67 VICTOR PRUS INC.6167-70 QUEBEC CAFETERIA SERVICE LTD.5002-70 QUEBEC NORTH SHORE PAPER COMPANY 1513-38 REALTY PROJECTS (1957) INC.11705-57 RECHERCHES EN COMMUNICATIONS DE MASSE DU QUEBEC INC.QUEBEC RESEARCH IN MASS COMMUNICATIONS INC.731-70 RELIURE BOUTHILLIER-BEAUDOUIN INC.3399-71 07 10 70 781, avenue Marois, Québec.15 10 65 1516.Place Ville-Marie, Dorchester.Montréal.09 03 65 1977 Grand Trunk, Montreal 27 06 69 11007, rue St-Réal, Montréal.14 04 70 Montréal 29 12 69 Montréal 15 07 70 4630, avenue Harvard, Montréal.18 03 71 2800, rue Descoteaux, Sherbrooke.11 02 55 51, Sault au Matelot, Québec.03 07 63 37, rue Fleury.Vimont 29 12 67 1815, rue de La Salle, Montréal.23 11 70 1290, avenue des Pins ouest, Montréal.16 11 70 Sherbrooke.08 07 38 Montréal.17 05 57 Montreal .04 03 70 351, Place Royale, Montréal.18 02 72 1221, rue Berthier, Longueuil.8790, avenue du Parc, Montréal.3900, boulevard Rose-mont, app.4, Montréal.60, route Trans-Canada.Lévis.440, boulevard St-Cyrille ouest, Québec.769, Place Victoria, Montréal.5010 Angers, Montreal.166, rue St-Amable, Montréal.2050, boulevard Maison-neuve ouest, suite 602, Montréal.6848, rue Drolet, Montréal 327.4073, rue St-Hubert, Montréal.2860, Place Marquette, Laval.359, boulevard Charest est, Québec.16, rue Bellerose est, Vimont.3810, rue Rachel est, Montréal.1420, rue Sherbrooke ouest, Montréal.1417, rue Desjardins, Sherbrooke.1245, rue Sherbrooke ouest.Montréal.2050 Mansfield.10th Floor, Montreal.630 ouest, rue Sherbrooke, Montréal.2123, rue Ste-Hélène, Longueuil. 3624 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address RENNAT ENTERPRISES LIMITED.28 07 71 Montréal.1160, Louvain Street West, 714061 Montréal.RESTAURANT LA RAPIERE INC.10 01 69 2077, rue St-Denis, 1490, rue Stanley, 176-69 Montréal.Montréal.REX TRAVEL AGENCY INC.03 07 69 Montréal.5622, a,venue Park, 3247-69 Montréal.ROUDAN INC.16 03 71 1005, rue De Bullion, 970.avenue Hôtel de 1458-71 Montréal.Ville, Montréal.ROGER ROUGIER LTEE.19 06 61 Montréal.970.avenue Hôtel de ROGER ROUGIER, LTD.Ville, Montréal.13153-61 RUSSELL HOLDINGS LIMITED.16 02 71 Montréal.1439, rue 8t>Mathieu, 746-71 Montréal.S.* A.MFG.LTD.14 05 58 60, rue Jean-Talon ouest, 9124, rue Sfc-Laurent, 11606-68 Montréal.Montréal.8EMAC INVESTMENT INC.21 12 64 2647, rue Allard, 6285, boulevard Monk, 5837-64 Montréal.Montréal.SERVICE DE PREPARATION AU MARIAGE 08 06 64 Montréal.190, rue De Castelneau DE MONTREAL INC.est, Montréal.2066-64 SERVICE D'ENTRETIEN PREVENTIF 23 11 71 Sherbrooke.1432, rue King ouest, (QUEBEC) INC.Sherbrooke 716418 LA SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE 08 05 69 768, rue St-Joseph est.250, Grande-Allée ouest, CONSULTATION (S.A.C.) INC.Québec.#1709, Québec.SOCIETY OF ADMINISTRATION AND CONSULTATION (S.A.C.) INC.2174-69 SPARTI SPORTSWEAR INC.14 02 73 5417, boulevard 8t~ 7180, rue 8t-Urbain LES VETEMENTS SPORT SPORTI INC.Laurent, Montréal.Mo™réal ' 730667 fIS SfORTIFS DU QUEBEC INC.26 04 63 251, Dorchester sud, 6265, 3e Avenue ouest, 1900-63 Québec.Charlesbourg.?T,UDA° 2 PLUS 2 INC03 00 65 10710, rue Péloquin, 1110, rue Sherbrooke 3931-66 Montréal.ouest, suites 506-50, Montréal.8Y^y,IA KNITWEAR LTD.02 09 71 Montréal.83.rue Rachel eat.714587 Montréal.*mraninmK.27 0165 Quéw.2oaxc8t-paui- 10239-65 yuerjec.TAPIS ET DECORATION B A G INC.21 03 73 8aint-Basile-le-Grand.149.rue Principale.\",WB* Saint-Basile-le-Grand.TAVERNE LE BARIL INC02 02 87 Saint-Jérôme.226.rue Brière, Saint- 205-67 Jérôme.n^N7I5fiUMITEE11 06 58 1465 Union Avenue, 1166 Dorchester Boule- * ¦ 00 Montreal.vard West, Montreal.99^o8THIBAULTETFIL8LIMITEE19 03 68 160.rue Du Rocher.220.me Du Rocher, Chicoutimi-Nord.Chicoutimi-Nord.TOUlfflOIMIDGETRKIONAlD'ALMAINC.23 03 73 1160.Boivin ouest.Alma.995.Notre-Dame ouest.Aima. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3625 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address TRADUCTIONS TRAVEX INC.4624-70 TRANSPORT DOUCET LIMITEE.781-63 LES TRANSPORTS DU GOLFE INC.5124-66 TREJEAN, INC.10161-67 TROIS-RIVIERES READY MIX INC.721333 22 10 70 Montréal.18 02 63 9, rue Tanguay, Rimouski.18 lt 65 175, del'Evêché ouest, Rimouski.18 01 57 201, rue Principale sud, Amos.A.FRS TURCOTTE INC.3748-70 TWIN PRESTIGE CHIFFON LTD.LES CHIFFONS JUMELES PRESTIGE LTEE 3965-70 UNIFORMES MODERNES (MONTREAL) INC.MODERN UNIFORMS (MONTREAL) INC.1203-65 10 03 72 Trois-Rivières.31 08 70 Québec.10 09 70 Montréal.VACHON TRANSPORT INC.5282-69 VOYAGE DEUX MILLE INC.725170 NANCY WIGS INC.4716-70 18 03 65 Montréal.WILLIAMS HOLDING INC.4058-69 05 11 69 10874, St-Vital, Montréal-Nord.14 09 72 7765, Le Bourgeois, Québec 7.29 10 70 7609, rue St-Hubert, Montréal.20 08 69 Hull.2055, rue Peel, suite 925, Montréal.407, rue Rouleau, Rimouski.380, de la Cathédrale, Rimouski.11, rue Principale nord, Amos.1250, Père Marquette, Trois-Rivières.58, rue St-Pierre, Québec.No 2 Store, Place Ville Marie (ruelle), Montréal.1900, rue Sauvé est, Montréal.10885, rue St-Vital, Montréal-Nord.4765 - 1er Avenue, Québec 7.2595, rue Fleury est, Montréal.950, boulevard St-Joseph, Hull.Le directeur du service des compagnies, 67195-o Pierre Desjardins.\t57195-0\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.Avis de correction (Lettres patentes)\tNotice of correction (Letters patent)\t Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: panies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Nom / Name Siège social Incorporation Head office Date Modifications Corrections LES EQUIPEMENTS J.S.L.(MATANE) INC.107, rue Fra- 26 1367-1649 ser.Rivière- du-Loup.LES REGATES INTERNATIONALES DE 328, rue de BELOEIL INC.Rouville, 739002 Beloeil.02 74 Corrigeant le nom / Correcting the name: LES EQUIPEMENTS J.L.S.(MATANE) INC.par / by LES EQUIPEMENTS J.S.L.(MATANE) INC.11 12 73 Corrigenat le nom / Correcting the name: LES REGATES INTERNATIONALES DE BELOEIL par / by LES REGATES INTERNATIONALES DE BELOEIL INC. 3626 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom / Name Siège social Head office Incorporation Date Modifications Corrections SPIE-BATIGNOLLES (QUEBEC) LIMITEE.Montreal.746073\t\u2022\u2022 11 °' 74 ^É^s^^^^ TEE par / by SPIE-BATIGNOLLES (QUEBEC) LIMITEE SUPERMARCHE PLACE ROLLAND INC____ Montreal-1364301 Nord.\t17 01 74 Remplaçant le d^m/Rtp^nofAe name: SUPERMARCHE PLACE ROLLAND INC.par le nom / by the name: SUPERMARCHE PLACE ROLLAND INC.Le directeur du service dee compagnies, 67196-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 67195-0 Director of the Companies Service.Fusion de compagnies\tAmalgamation of Companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Fusion Nom des compagnies Nom de la nouvelle compagnie Siège social Amalgamation fusionnées Name of new company Heed office Name of companies Date amalgamated\t ANGELICA-WHITE WEAR LTD.Montreal.ANGELICA-WHITEWEAR LTEE 1364-4242\t.28 02 74 ANGELICA UNIFORMS (CANADA) LIMITED LES UNIFORMES ANGELICA (CANADA) LIMITEE WHITEWEAR MFG.CO.LTD.ST.JOSEPH MANUFACTURING COMPANY LTD.COMPAGNIE MANUFACTURIERE ST.JOSEPH LTEE Le directeur du service des compagnies, 67196-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 57195-0 Director of the Companies Service.Avis d'annulation de chartes (2e avis)\tNotice of annulment of charters (2nd notice) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que les chartes des compagnies ou corporations ci-dessous désignées sont annulées en vertu de la Loi des compagnies:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, the charters of the following companies or corporations are annulled.Nom de la compagnie ou corporation / A/ame of company or corporation Incorporation Date\t DUROGRAF INTERNATIONAL LIMITED.12269-54 15 09 64 57196-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195-0 Pierre Desjardins.of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3627 Changement de nom Change of name Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a approuvé les règlements de changement de nom suivant: Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date BETONS B.G.INC.10451-61 CHAPDELAINE & PAQUETTE, ASSURANCES, INC.5445-70 CHARRON CLUTCH-MOTOR LTD.EMBRAYAGE-MOTEUR CHARRON LTEE 986-65 CIE DE BIJOUTBRIE CONTINENTAL.CONTINENTAL JEWELLERY CO.9446-52 DUFALCO INC.737966 YVON FERLAND INC.732199 GALERIE DES TAPIS PERSE LTEE.GALLERY OF PERSIAN CARPETS LTD.738526 LES INDUSTRIES G.COLLIN INC.G.COLLIN INDUSTRIES INC.722368 INSTITUT PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE I.P.I.INC.3725-71 PARIS STAR KNITTING MILLS INC.« PARIS STAR », BONNETERIE INC.11892-1955 LES PLACEMENTS GENDOR LTEE.GENDOR INVESTMENTS LTD.721692 RESIDENCES MAROIS LTEE.M A KO IS RESIDENCES LTD.12016-62 SERVICE PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE S.P.I.INC.3724-71 TALONS DE BOIS LAPRAIRIE INC.LAPRAIRIE WOOD HEEL INC.13512-55 YELLOW SHOES LTD.CHAUSSURES < YELLOW » LTEE 12132-1955 BETONS RICHELIEU INC.16 02 61 RICHELIEU READY-MIX INC.F.CHAPDELAINE ASSURANCES INC.08 01 71 CHARRON AUTOMOTIVE LTD.23 03 65 CHARRON AUTOMOTIVE LTEE CONTINENTAL JEWELLERY COMPANY.26 06 52 FALCO INC.24 08 73 DACTYLOGRAPHE FERLAND INC.14 06 73 TAPIS MAGIE DE PERSE LTEE.22 10 73 PERSIAN MAGIC CARPET LTD.LES INDUSTRIES G.COLLIN INC.02 05 72 INSTITUT PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE DE LEVIS INC.12 07 71 PARI8 STAR KNITTING MILLS INC.08 07 65 EASTON INVESTMENTS LTD.21 03 72 PLACEMENTS EASTON LTEE NURSES CONVALESCENT HOME LTD.06 09 63 SERVICE PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE DE LEVIS INC.12 07 71 LAPRAIRIE WOOD HEEL INC.27 12 55 YELLOW SAMPLE SHOE STORES LIMITED .09 08 55 57195-0 Le directeur du service dee compagnies, Pierre Desjardins.57196-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 3628 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Siege social (Art.84) Head office (Art.84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci-après.Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed their head office as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address a-z tooling & machine works ltd.4623-69 aero hydraulics corporation.la corporation aero hydraulique 13981-ot allied record corporation.CORPORATION DE DISQUES ALLIED 13691-62 L'ASSOCIATION DES GROUPES D'ARTISANS D'ABITIBI-TEMISCAMINGUE 717253 LES AUTOBUS BELLEMARE & FRERES LTEE 737768 30 09 69 LaBalle.04 08 61 300 Youville Square, Montreal.07 09 62 400 Industrial Avenue, Ottawa, Ontario.28 12 71 Rouyn.BELRAMPA INC.729303 BIOCURA INC.3121-71 michel bolduc construction inc .CONSTRUCTION MICHEL BOLDUC INC.73-0067 LA BOUTIQUE MARIE-JOSEE INC.217-70 8ALVATORE BRICKLING INC.72-2943 BROSSARD DOUGHNUT SHOP LTD.6217-69 BRUNET & BERGERON INC.1645-71 CAFETERIAT PROVINCIALE INC.2634-71 CAMPEAU-WESTMOUNT INC.625-63 capitol automatic distributors ltd LES DISTRIBUTRICES AUTOMATIQUES CAPITOL LTEE 2679-70 J.E.CHARETTE DESIGNER8 INC.930-70 charland ave.iron works company ltd.10318-60 la CU3 de placements polara ltee .pol ara investment co.ltd.11991-60 02 08 73 501, rue Bois Blanc, Saint-Justin.06 11 72 5260.rue Durocher, Outremont.09 06 71 11180, London, Montréal-Nord.09 01 73 2982, Place des Pins, Shawinigan.20 01 70 Lebel-sur-Quévillon.26 05 72 60, 15e Avenue, Laval.19 11 69 Brassard.31 03 71 Charlesbourg.19 06 71 685, boulevard Hamel, Québec.04 02 63 132, rue St-Jacques, Chomedey.18 06 70 1000 Amherst Street, Montreal.02 03 70 Montreal.26 01 60 2730.avenue Charland.Montréal.29 04 60 8250.boulevard Château-neuf, Anjou.450, rue Michel Jasmin, Dorval.10340.Côte-de-Liesse.Lachine.5700 Ferrier Avenue, Montréal.120, rue Villeneuve, Val-d'Or.485, rue Beaudry, app.2, Cap-de-la-Màdeleine.20, rue Elgin, Place Bonaventure, Montréal.50, Place Crémazie, suite 528, Montréal.630 - 129e Rue.Shawinigan-Sud.1055, avenue Dupont, Les Galeries Lac Saint-Jean, Aima.7761, rue Châteauneuf, suite 101, Anjou.Longueuil.1225.rue Jean-Talon est.Montréal.1.rue Notre-Dame, Montréal.6600, Côte des Neiges, Montréal.711 Riddle Street, Dorval.2 Westmount Square, suite 304, Westmount.8810.boulevard Pascal-Gagnon, Saint-Léonard.238, rue Lanoue, Repenti-gny. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3629 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address CLEANING EQUIPMENT & PRODUCTS (MONTREAL) LTD.2751-69 CLINIQUE DE PHYSIOTHERAPIE DES LAURENTIDES INC.724577 CLUB D'AVIATION VENUS INC.4042-70 CLUB DE MOTOS-NEIGE ASAN INC.720363 LA COMPAGNIE DES TERRAINS DE LAVAL, INCORPOREE 1222-12 LA COMPAGNIE MINIERE SOMIPE LIMITEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 3271-70 THE CONSOLIDATED FUND LTD.6785-64 02 07 69 Montréal.8930, rue Racicot, Bro3sard.16 08 72 Saint-Jérôme.447, boulevard des Lau- rentides, Saint-Antoine-des-Laurentides.16 09 70 Trois-Rivières-Ouest.1735, rue Croix du sud, Gentilly.24 01 72 Saint-Barnabé.139, rue Pinard, Saint- Thomas-d'Amqui.13 04 12 Laval.10, rue St-Jacques ouest, Montréal.CONSTRUCTION ALBEC LTEE.ÂLBEC CONSTRUCTION LTD.10434-61 28 07 70 1019, boulevard St- Cyrille ouest, Sillery.29 12 64 1876 - 52nd Avenue, Lachine.21 03 61 110, rue Corbeil, Hull.CONSTRUCTION H.V.E.INC.H.V.E.CONSTRUCTION INC.737953 CONSTRUCTION R.G.L.LTEE.721374 CONTRACTORS SUPPLIES LIMITED.9519-49 24 08 73 Saint-Joseph-du-Lac.985, avenue des Braves, Québec.4862.Côte-des-Neiges.suite 10, Montréal.3.avenue de Picardie, Touraine.1155, boulevard Dorchester ouest, suite 3301, Montréal.CREDIT CARDINAL INC.1372-65 D.G.A.SPORTING GOODS AGENCIES LTD .1193-71 DAIGLE TIRE SERVICE LIMITED .11793-57 72 20 St-Josephat Avenue, Pointe Gatineau.50 335, chemin Côte St-Louis, Blainville.71 6700, Donahue, Saint-Laurent.JACQUES DARCHE INC.2707-69 DESILETS & FILS LTEE.4776-66 09 03 10 02 31 03 66 Rouyn.Ill, 12e Rue, Noranda.11 03 27 05 57 245 - 2e Rue.Québec 09 06 13 Forget Street, Templeton.1950, boulevard Sir Wilfrid Laurier, Saint-Hubert.9353, chemin Côte-de-Liesse, Dorval.2200, Ste.Catherine Street East, Montreal.Route rurale numéro 2, Sherbrooke.Rue Principale, Sainte-Catherine-de-Hatley, Stanstead.DEXAM INC.3742-71 THE ELECTRICAL MAINTENANCE ASSOCIATION OF MONTREAL & DISTRICT 10441-59 LES ENTREPRISES DEBLOIS LTEE.1200-67 09 12 65 Rouyn.Evain.13 00 09 02 59 Verdun 71 2740, boulevard Pitfield, Saint-Laurent.219, rue St-Georges, Beloeil.3740, rue St-Kevin, app.6, Montréal Métropolitain.LES ENTREPRISES DOMCOR (QUEBEC) LIMITEE DOMCOR ENTERPRISES (QUEBEC) LIMITED 2074-48 20 03 67 Québec 14 02 48 6175 Metropolitan Boulevard East, Montreal.1401, rue Fitz Patrick, Sillery.6125 Metropolitan Boulevard East, Saint-Léonard. 3630 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, So.SO Siège social Incorporation Head office_ Nom de la compagnie -\"\u2014~ Tt Z Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address ERGE INC.13 04 72 Rouyn.2595, rue Saguenay.721271 Noranda.FABRAPLY INC.05 07 68 Lachine.2121 Hingstone Avenue, 3032-68 Montreal.EMILE FERLAND INCORPOREE.21 11 60 473, 2e Rue, Québec.1264, Royale, Saint- 14770-60 Pierre, He d Orléans.FINE MFG.CO.LTD.18 09 56 5174, chemin Côte des 10229, chemin Côte-de- 12770-56 Neiges, Montréal.Liesse.Dorval.LUCIEN GARIEPY ET ASSOCIES INC.23 05 69 3618, boulevard de la 9270, rue Chateaubriand, 2341-69 Concorde, Laval.Montréal.GOODFELLOW COMBUSTION (QUEBEC) INC 16 12 70 Saint-Pierre.630 Dorchester 5593-70 Boulevard West, Montreal.C.H.HEIST LTEE.24 11 67 1 Place Ville-Marie, 11426 Cherrier Street, 4897-67 suite 3635, Montreal.Montreal-East.LES IMMEUBLES CLICHE LTEE.11 12 64 215, rue St-Jacques, Saint-Georges, Beauce.5372-64 Montréal.LES IMMEUBLES SHERBROOKE INC.29 01 73 Montréal.103.Montée du Moulin, 730347 Laval.IMPORTATION D'EQUIPEMENTS ELECTRO- 14 11 72 Montréal.1038, rue Shorecrest, Laval NIQUES APOLLO LTEE.apollo electronic import ltd 726115 INMAR CO.LTD.30 03 65 5520 Victoria Avenue, apt.1 Place Ville Marie, suite 1359-66 1, Westmount.3635, Montreal.JACEMAR INC.04 12 72 1117, rue Ste-Catherine 1110, boulevard 726430 ouest, Montréal.Provencher, Brossard.JOU?iMirDK°,^P,0,Ri^,U 28 12 50 1155 Dorchester Street 213 - 1st Avenue West.noA0(NP PERS0NAL LIABILITY) West, Montreal.Amos.9208-50 ?£?eMÂT \"^VESTMENTS LTD.30 04 69 6655 Fielding Avenue, 2076 Victoria, suite 102, 12675-59 Montreal.Saint-Lambert.LABORATOIRE DEMERS LTEE22 04 58 °-uébec.2721.rue du Général 10958-58 Tremblay.Sainte-Foy.LTt^IÎbIIa°F0\\V^.30 03 60 m°nt'éal22vfneMd°enlt!.t-aubid- 3209-60 Vl\"e ae ^aval- WaSS*' RIVARD 4 ASSOCIES INC.20 12 68 Québec.Montréal.MMWH*0 INC06 03 62 \"°.™e Corbeil.Hull.3, avenue de Picardie.Touraine.LAURENTIDE DISPLAYS INC.M 02 63 Chomedey (Laval).7336.rue St-Laurent, Montréal.122U)-58R kAVIGNE âc FILS INC.26 06 58 Québec.476, avenue Pruneau, Vanier.818-67 .23 02 67 1135, Chemin St-Louis, 65, rue Ste-Anne, Québec.Sillery.EXPRES^CLAUDE^LEVERT^NC10 10 73 49,2!' rue Parier, Saint- Saint-Edouard./38400 Léonard. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3631 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address LA LOCHE LUMBER CO.LTD.11700-54 MAURICE & CLAUDE CO.LTEE.10675-54 MEUBLES ET DECORS MIRAGE (LAVAL) INC.MIRAGE FURNITURE AND DECOR (LAVAL) INC.733854 MEUNERIE LAVAL LIMITEE.12039-58 THOMAS MIGNAULT & FILS INC.220-68 PAVAGE ORSAINVILLE INC.1829-69 17 06 54 66, rue St-Pierre, Québec.1924, rue Monument, Giffard.12 03 54 222, rue Principale nord.1540, rue O'Reilly, Windsor.Sherbrooke.04 09 73 4690 Sources Road, Dollard-des-Ormeaux 2260 - 46th Avenue, Lachine.PLACEMENTS DeBLOIS INC.4060-68 PLACEMENTS DORION INVESTMENTS INC.14616-58 LES PLACEMENTS MONOR INC.MONOR INVESTMENT INC.11553-61 12 07 58 Sainte-Angèle de Laval____ Saint-Hyacinthe.17 01 68 Saint-Philippe-de-Néri____ Route 230.Saint-Pascal.14 05 69 1649, Moselle, Orsainville .06 09 68 Québec.12 12 68 Dorion.04 04 61 Montréal.2370, boulevard Hamel, Québec.1401, rue Fitz Patrick.Sillery.420, boulevard Roche, Vaudreuil.PLACEMENTS RACINE INC.1591-63 POLIMPORT CORPORATION.13210-62 QUEBEC GUNITE MARINE INC.1578-68 ROBAC INC.2072-70 S.& N.RUBIN CORP.2963-69 SERVICE DE CONSULTATION EN PERSONNEL H.C.C.INC.H.C.C.CONSULTATION SERVICE IN PERSONAL INC.737634 SERVICE PROFESSIONNEL D'INFORMATIQUE DE LEVIS INC.3724-71 SOCIETE DE GESTION DEÇA INC.3383-67 09 04 63 2700, boulevard Laurier, Sainte-Foy.22 08 72 1875 - 52nd Avenue, Lachine.05 04 68 Sillery.11 05 70 65, rue Ste-Anne, suite 409, Québec.16 06 69 3905, Edouard Montpetit Boulevard, Montreal.13 07 73 9, Cedar Circle, Dollard-des-Ormeaux.615, boulevard St-Germain ouest, Rimouski.800, d'YouviUe, Québec.4862, Côte des Neiges, suite 10, Montreal.1762, route de L'Aéroport, Ancienne-Lorette.534 Montford Drive, Dollard-des-Ormeaux.3150, Sartelon, Saint-Laurent.9, Riverside Drive, Saint-Lambert.SOCIETE IMMOBILIERE TOURMALINE INC.736859 LA SOCIETE TRANS-QUEBEC LTEE .14295-62 8TONECREST CONSTRUCTION LTD.330-68 TRASOR INC.2263-67 12 07 71 Lévis.350, chemin Ste-Foy.Québec.04 08 67 Montréal.12635, rue Lacordaire, Montréal-Nord.18 04 73 235, boulevard Dorchester, 145, De Navarre, Saint-suite 604, Montréal.Lambert.22 10 62 Montréal.395, rue Bérubé, Vanier.23 01 68 3510 St.Joseph Boulevard 809 Deslauriers, Saint-East, Montreal.Laurent.08 05 67 2505, boulevard Cournoyer, 260, rue Prince, Sorel.Tracy. 3632 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.May 18.1974.Vol.106.No.SO Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address trois-rivieres paper box ltd.LA CIE DE BOITES TROIS-RIVIERES LTEE 11812-54 TUCCI.MONTPETIT INSURANCE BROKERS INC.812-70 VOTRE CHOIX TRANSPORT INC.02 3465-65 09 07 54 Trois-Rivières.7612.17e Avenue, Shawinigan.24 02 70 4280 Métropolitain est, Saint-Léonard.7715, Papineau, app.103, Montréal.08 65 Pointe-au-Père.270.rue Léonidas, Rimouski.57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Canton de Babel Cadastre officiel du canton de Babel, municipalité de la ville de Port-Cartier, division d'enregistrement de Saguenay.Avis est par la présente donné que les lots 2-85 du bloc 2 et 1-362 du bloc 1 et 1-381 du bloc 1 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 19 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Township of Babel Official cadastre of township of Babel, municipality of the town of Port-Cartier, registration division of Saguenay.Notice is hereby given that lots 2-85 of block 2 and 1-362 of block 1 and 1-381 of block 1 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 19, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Canton de Babel Cadastre officiel du canton de Babel, municipalité de la ville de Port-Cartier, division d'enregistrement de Saguenay.Avis est par la présente donné que les lots 1-628, 1-629 du bloc 1 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 18 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-o Benoît Grimard, a.-o.Ville de Drummondville (Quartier est) Cadastre officiel de la ville de Drummondville (Quartier est), municipalité de la cité de Drummondville, division d'enregistrement de Drummond.Avis est par la présente donné que le lot 633 est ajouté et qu'une partie des lots 123, 124, 165 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 18 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Township of Babel Official cadastre of township of Babel, municipality of the town of Port-Cartier, registration division of Saguenay.Notice is hereby given that lots 1-628, 1-629 of block 1 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March IS, 1974.Benoît Grimard, a.-o., For the Deputy Minister.57199-0 Town of Drummondville (East Ward) Official cadastre of the town of Drummondville (East Ward), municipality of the city of Drummondville, registration division of Drummond.Notice is hereby given that lot 633 is added and that a part of lots 123, 124.165 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 18, 1974.Benoît Grimard, a.-o., °< 1 99-0 For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° SO 3633 Canton de Granby Cadastre officiel du canton de Granby, municipalité du canton de Granby, division d'enregistrement de Shefford.Avis est par la présente donné que les lots 498-13 à 498-15 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 avril 1974.Four le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Canton de Grantham Cadastre officiel du canton de Grantham, municipalité de la cité de Drummondville, division d'enregistrement de Drummond.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 119-29, 119-30, 119-31, 119-36, 119-37, 119-38, 119-45, 119-46 et des lots 119-27, 119-28, 119-32, 119-33, 119-34, 119-35, 119-39, 119-40, 119-41, 119-42, 119-43, 119-44, 119-47, 119-48, 119-49 et 119-50 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 24 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Township of Granby Official cadastre of township of Granby, municipality of township of Granby, registration division of Shefford.Notice is hereby given that lots 498-13 to 498-15 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 4, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Towhship of Grantham Official cadastre of township of Grantham, municipality of the city of Drummondville, registration division of Drummond.Notice is hereby given that a part of lots 119-29, 119-30, 119-31, 119-36, 119-37, 119-38, 119-45, 119-46 and that lots 119-27, 119-28, 119-32, 119-33, 119-34, 119-35, 119-39, 119-40, 119-41, 119-42, 119-43, 119-44, 119-47, 119-48, 119-49 and 119-50 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec April 24, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Village de Megan tic Cadastre officiel du village de Mégantic, municipalité de la ville de Lac-Mégantic, division d'enregistrement de Frontenac.Avis est par la présente donné que les lots 909 à 1012, 1079 à 1099, 1108 à 1132, 1145 à 1161, 1165 à 1174 et qu'une partie du lot 2373 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repentigny Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repentigny, municipalité de la ville de Repentigny, division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que le lot 207 est ajouté et que les lots 49-8, 49-9, 49-10, 50-7, 50-10-1 et qu'une partie des lots 49, 50-9, 50-10 et 50 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 8 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Alban d'Alton Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Alban d'Alton, municipalité du village de Saint-Marc-des-Carrières, division d'enregistrement de Portneuf.Village of Mégantic Officiai cadastre of village of Mégantic, municipality of the town of Lac-Mégantic, registration division of Frontenac.Notice is hereby given that lots 909 to 1012, 1079 to 1099, 1108 to 1132, 1145 to 1161, 1165 to 1174 and that a part of lot 2373 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 21, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy M inister.Parish of Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repentigny Official cadastre of the parish of Notre-Dame-de-l'Assomption-de-Repentigny, municipality of the town of Repentigny, registration division of L'Assomption.Notice is hereby given that lot 207 is added and that lots 49-8, 49-9, 49-10, 50-7, 50-10-1 and that a part of lots 49, 50-9, 50-10 and 50 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 8, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Alban d'Alton Official cadastre of the parish of Saint-Alban d'Alton, municipality of village of Saint-Marc-des-Carrières, registration division of Portneuf. 3634 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 22-5 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Notice is hereby given that a part of lot 22-5 i cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 25, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Athanase Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Athanase, municipalité de la paroisse de Saint-Athanase, division d'enregistrement d'Iberville.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 328-9 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 2 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Athanase Official cadastre of the parish of Saint-Athanase, municipality of the parish of Saint-Athanase, registration division of Iberville.Notice is hereby given that the remaining part of lot 328-9 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 2, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Benoît Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Benoit, municipalité de la ville de Mirabel, division d'enregistrement de Deux-Montagnes.Avis est par la présente donné que les lots 58-5, 58-14, 58-27 à 58-30, 58-50, 58-114, 58-115, 58-150, 58-151.58-152, 58-203, 58-242, 58-254, 58-255, 58-256, 58-260 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 18 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Benoît Official cadastre of the parish of Saint-Benoît, municipality of the town of Mirabel, registration division of Deux-Montagnes.Notice is hereby given that lots 58-5, 58-14, 58-27 to 58-30, 58-50, 58-114, 58-115, 58-150, 58-151, 58-152, 58-203, 58-242, 58-254, 58-255, 58-256, 58-260 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 18, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Eustache Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Eustache, municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac*, division d'enregistrement de Deux-Montagnes.Avis est par la présente donné que les lots 146-890 à 146-893 et qu'une partie des lots 146-410, 146-798, 146-819 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 14 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Eustache Official cadastre of the parish of Saint-Eustache, municipality of Sainte-Marthe-sur-le-Lac*, registration division of Deux-Montagnes.Notice is hereby given that lots 146-890 to 146-893 and that a part of Tots 146-410, 146-798, 146-819 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 14, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Féréol Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Féréol, municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges*, division d'enregistrement de Montmorency.Avis est par la présente donné que le lot 650 est ajouté et que les lots 491-44.491-45.493-54, 493-55.493-56, 493-57 et qu'une partie des lots 491 el 493 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 avril 1974.Pour le sous-ministre.57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Féréol Official cadastre of the parish of Saint-Féréol, municipality of Saint-Féréol-les-Neiges*, registration division of Montmorency.Notice is hereby given that lot 650 is added and that lots 491-44, 491-45, 493-54, 493-55, 493-56, 493-57 and that a part of lots 491 and 49i> are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 5, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-o For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3635 Paroisse de Saint-FIavien Cadastre officiel de la paroisse de Saint-FIavien, municipalité du village de Saint-FIavien, division d'enregistrement de Lotbinière.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 414-4, 414-18 et que les lots 414-4-6 à 414-4-8, 41-.-18-2, 414-19-1, 414-19-2, 414-20-1, 414-20-2, 414-19 à 414-21 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 26 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Chrysos-tome, municipalité de la ville de Sainl-Jean-Chysos-tome, division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné que les lots 264-5, 264-6 et que la partie restante du lot 264-7 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 29 mars 1974.Pour le sous-ministre, 57199-o Benoît Grimard, a.-g.Village de Saint-Jérôme Cadastre officiel du village de Saint-Jérôme, municipalité de la ville de Saint-Jérôme, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 469-32, 469-37, 469-36, 469-39, 469-46, 469-53, 469-55, 469-56, 469-122 et des lots 469-38, 469-40 à 469-45, 469-57 à 469-121 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 mars 1974.Pour le sous-ministre.57199-0 Benoît Grimard.a.-g.Paroisse de Saint-Luc Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Luc, municipalité de la ville de Saint-Luc, division d'enregistrement de Saint-Jean.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 140-35 et qu'une partie des lots 140-22 à 140-28, 140-17 à 140-20 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 1 avril 1974.Pour le sous-ministre.57199-0 Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipalité de la cité de Sainte-Thérèse, division d'enregistrement de Terrebonne.Parish of Saint-FIavien Official cadastre of the parish of Saint-FIavien, municipality of village of Saint-FIavien, registration division of Lotbinière.Notice is hereby given that a part of lots 414-4, 414-18 and that lots 414-4-6 to 414-4-8, 414-18-2, 414-19-1, 414-19:2, 414-20-1, 414-20-2, 414-19 to 414-21 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 26, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Jean-Chrysostome Official cadastre of the parish of Saint-Jean-Chrysostome, municipality of the town of Saint-Jean-Chrysostome, registration division of Levis.Notice is hereby given that lots 264-5, 264-6 and the remaining part of lot 264-7 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 29, 1974.Benoît Grimard, a.-g.57 1 99-o For the Deputy Minister.Village de Saint-Jérôme Official cadastre of village de Saint-Jérôme, municipality of the town of Saint-Jérôme, registration divison of Terrebonne.Notice is hereby given that a part of lots 469-32, 469-37, 469-36, 469-39, 469-46, 469-53, 469-55, 469-56, 469-122 and that lots 469-38, 469-40 to 469-45, 469-57 lo 469-121 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 21, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Parish of Saint-Luc Official cadastre of the parish of Saint-Luc, municipality of the town of Saint-Luc, registration division of Saint-Jean.Notice is hereby given that the remaining part of lot 140-35 and that a part of lots 140-22 to 140-28, 140-17 to 140-20 is cancelled in virtue of article 2174a of Civil Code.Québec, April 1, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 57199-o For the Deputy Minister.Parish of Sainte-Thércse-de-Blainville Official cadastre of the parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipality of the city of Sainte-Thérèse, registration division of Terrebonne. .'iii.ii; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 19U, Vol IPG, So.20 Avis est par la présente donné que le lot 766-33 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 19 mars 1962 Pour le sous-ministre, 57199-0 BenoIt Grimard, a.-g.Paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipalité de la ville de Sainte-Thérèse-Oiir-t, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 94-57, 95-140, 95-362, et des lots 94-58, 94-181 à 94-223, 95-134 à 95-139, 95-296 à 95-361 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 1 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 Ben'oIt Grimard, a.-g.Paroisse de Sainte-Victoire Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Victoire, municipalité de la ville de Victoriaville, division d'enregistrement d'Arthabaska.Avis est par la présente donné que les lots 24-33-6 à 24-33-8 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 19 avril 1974.Notice is hereby given that lots 766-33 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, March 19, 1962.BenoIt Grimard, a.-g., 57 j 99^, For the Deputy M in inter.Parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville Official cadastre of the parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipality of the town of Sainte-Ihe-rèse, registration division of Terrebonne.Notice is hercbv given that a part of lots 94-57, 95-140, 95-362 and that lots 94-58, 94-181 to 94-223, 95-134 to 95-139, 95-296 to 95-361 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.April 1, 1974.BenoIt Grimard, a.-g., 57199-0 For the Deputy Minister.Parish of Sainte-Victoire Official cadastre of the parish of Sainte-Victoire, municipality of the town of Victoriaville, registration division of Arthabaska.Notice is hereby given that lots 24-33-6 to 24-33-8 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.57199-0 Pour le sous-ministre, BekoIt Grimard, a.-g.Québec.April 19, 1974.57199-o BenoIt Grimard, a.-g., For the Deputy Minister.Canton de Wendover Cadastre officiel du canton de Wendover, municipalité des cantons unis de Wendover et Simpson, division d'enregistrement de Drummond.Avis est par la présente donné que les lots 3-87 à 3-89, 3-116 à 3-162 du rang I sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 3 avril 1974.Pour le sous-ministre, 57199-0 BenoIt Grimard, a.-g.Township of Wendover Official cadastre of township of Wendover, municipality of united townships of Wendover and Simpson, registration division of Drummond.Notice is hereby given that lots 3-87 to 3-89, 3-116 to 3-162 of range I are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, April 3, 1974.BenoIt Grimard, a.-g., 57199-q For the Deputy Minister.Vente d'effets non réclamés Sale of Unclaimed Baggage LA CIE DE MESSAGERIES CP LIMITEE Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de juin, 1973, et non réclamés aux bureaux des « CP EXPRESS LIMITEE » à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 6e jour de juin, 1974, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.\u201e\u201e\u201e\u201e_ .\u201e Le vice-président.56967-15-6-o W.M.Riley.CP EXPRESS LIMITED Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of June, 1973, still remaining unclaimed in the offices of the \"CP EXPRESS LIMITED\" at different points in the Province of Québec, will be sold at Public Auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at eleven o'clock in the forenoon, on the 6th day of June, 1974, unless same shall be called for before that date, and all charges paid thereon.W.M.Riley, 56967-15-6-0 Vice-President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3637 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, .\\o.SO ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication: II \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provision of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date cf this publication.The applicants request from the Québec Transport Commission an increase of tariffs as regards the transportation by taxi-vehicles for the departure, the mile travelled and the minute of waiting in the conglomerations of Québec (A.36), LevisLauzon (A.35), Ste.Foy Sillery (A.38) and Charlesbourg Orsainville (A.25), and an abridgment of the time limit prescribed in section 2.9 of Regulation No.2 on the rules of practice of the Québec Transport Commission.Rôle Q-1184 Q-24,007 D-l TF L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PROPRIÉTAIRES DE TAXIS DE QUÉBEC INC.a/s Boucher & Asselin, 1026, rue St-Jean.Québec.Les requérants font une requête à la Commission des transports du Québec pour obtenir une hausse des tarifs relativement aux transports par véhicules-taxis pour le départ, le mille parcouru et la minute d'attente pour les agglomérations de Québec (A.36), de LéviB Lauzon (A.35), de Ste-Foy Sillery (A.38) et de CharlesbourgOrsainville (A.25), et abrègement du délai prévu à l'article 2.9 du règlement No 2 sur les règles de pratiques de la Commission des transports du Québec.Rôle M-1014 1080 DYV D-2 THE LEASECUARD CORPORATION LIMITED, 3, Place Ville-Marie, suite 604.Montréal H3B 2E3, P.Q.Nouvelle demande.Correction de la demar.de publiée dans la Gazette officielle du Québec No 6.en date du 9 février, vol.106.à la page 1294; qui aurait dû se lire comme suit: Service: Location à long terme de camions, camions-tracteurs, remorques et fardiers, au grand public, au 3, Place Ville-Marie, bureau 604, Montréal.New request.Correction to the request which was published in the Québec Official Gazette No.6 of February 9th, Vol.106.Page 1294; should have read as follows: Service: Lease on a long term basis trucks, trucks tractors, trailers and floats, to the public in general, at 3.Place Ville-Marie, suite 604, Montreal.Rôle M-1015 32-DYA D-2 THE LEASECUARD CORPORATION LIMITED.3, Place Ville-Marie, suite 604.Montreal H3B 2E3.P.Q.Rôle M-1769 19749-V D-3 GÉRARD HARBEC TRANSPORT INC.200, Nord rue Comeau, Farnham, P.Québec.Nouvelle demande.Correction de la demande publiée dans la Gazette officielle du Québec No 6, en date du 9 février, vol.106, à la page 1294; et qui aurait dû se lire comme suit: Service: Location à long terme d'autobus et de minibus au grand public, au 3.Place Ville-Marie, bureau 604, Montréal.P.Q.La partie requérante demande l'autorisation de donner les services de transport suivants: 1) Transport restreint - longue distance -route restreinte - 1) De Farnham à Québec et Chicoutimi pour le transport de couvre-planchers (comme tuile et prélart) destinés aux distributeurs de Domco de Farnham et retour pour marchandises refusées ou endommagées.2) Transport restreint - longue distance-route restreinte - 2) De Farnham à Québec et Chicoutimi pour le transport de tapis destinés aux distri- New request.Correction to the request which was published in the Québec Official Gazette No 6 of February 9th, Vol.106, Page 1294 ; should have read as follows: Service: Lease on a long term basis, buses and minibuses to the public in general at 3.Place Ville-Marie, suite 604, Montreal, P.Q.The applicant requests authorization to provide the following transport services: (1) Restricted trucking - long distance -restricted route - (1) From Farnham to Québec and Chicoutimi for the transportation of floor-coverings (such as tile and linoleum) destined to Domco dealers in Farnham, and return with damaged or refused goods.(2) Restricted trucking - long distance -restricted route - (2) From Farnham to Québec and Chicoutimi for the transportation of carpets des- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3639 buteurs de Coronet Carpet Ltd.de Farnham et retour pour marchandises refusées ou endommagées.3) Transport restreint - longue distance -route restreinte - 3) De Farnham aux frontières Québec -Ontario (port d'entrée: Rivière-Beau dette et Rigaud) à destination d'Ottawa et Toronto pour le transport de prélarts et tuiles destinés aux distributeurs de Domco de Farnham et retour pour marchandises refusées ou endommagées.4) Transport restreint - longue distance -route restreinte - 4) De Farnham aux frontières Québec -Ontario (port d'entrée: Rivière-Beau dette et Rigaud) à destination d'Ottawa et Toronto pour le transport de tapis destinés aux distributeurs de Coronet Carpet Ltd.de Farnham et retour pour marchandises refusées ou endommagées.5) Transport restreint-longue distance -route restreinte - 5) De Farnham et de Acton Vale à Québec et Chicoutimi pour le transport de tapis et couvre-planchers destinés aux clients de Roger Sorel Tapis de Farnham et retour pour marchandises refusées ou endommagées.Rôle M-1770 13274-V D-l CLÉMENT TRANSPORT INC., 331, York, St-Barthélémy, cté Berthier, P.Que.Partie requérante / Applicant.146-DYL LES MEUBLES MASKINONGÉ INC., Maskinongé, Cté Berthier, Requérant conjoint Joint applicant.La partie requérante dont la clause e du permis se lit comme suit: Clause e : Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Maskinongé à tous les endroits situés dans la province de Québec à l'exception dee villes de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine pour le transport de meubles pour le compte de « Les Meubles Maskinongé Inc.», demande que le droit additionnel suivant soit ajouté à ladite clause e: 1) En donnant le service décrit à la clause ci-dessus mentionnée.la détentrice est également autorisée à transporter des meubles en utilisant les remorques appartenant à/et louées de Les Meubles Maskinongé Inc.les-dites remorques étant enregistrées à la province par ladite expéditrice et à la Commission par Clément Transport Inc.qui les tirera avec ses tracteurs dûment immatriculés à la Province et à la Commission.2) Le service décrit au droit additionnel précité sera fourni en utilisant les remorques appartenant à/et louées à Clément Transport Inc.par Les Meubles Maskinongé Inc.telle qu'autorisée par le permis pour ce faire qui a été émis à cette dernière par la Commission en date du 30 juillet 1973.Rôle M-1771 23770-V D-l FERNAND MALO, 890, Abbé Primeau, Boucherville, P.Québec.Requérant / Applicant, 17376-V D-6 KING SWAY FREIGHT LINES LTD., Calgary, Alberta.Requérant conjoint Joint applicant.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant conjoint: Kingsway Freight Lir.es Ltd., qui agira comme roulier: en vertu de toutes les clauses du permis permanent du roulier portant le munéro 17376-V.tined to dealers for Coronet Carpet Ltd., of Farnham, and return with damaged or refused goods.(3) Restricted trucking - long distance -restricted route - (3) From Farnham to the Québec-Ontario borders (ports of entry: Rivière-Beau dette and Rigaud) for furtherance to Ottawa and Toronto for the transportation of linoleum and tiles destined to Domco dealers, in Farnham, and return with damaged or refused goods.(4) Restricted trucking - long distance -restricted route - (4) From Farnham to the Québec - Ontario borders (ports of entry: Rivière-Beaudette and Rigaud) for furtherance to Ottawa and Toronto for the transportation of carpets destined to dealers for Coronet Carpet Ltd., of Farnham, and return with damaged or refused goods.(5) Restricted trucking - long distance -restricted route - (5) From Farnham and from Acton Vale to Québec and Chicoutimi for the transportation of carpets and floor-coverings destined to the customers of Roger Sorel Tapis, of Farnham, and return with damaged or refused goods.The applicant, clause e of whose permit reads as follows: Clause e: Restricted trucking-long distance-radius-contract - From Maskinongé to all points located in the Province of Québec, with the exception of the Cities of Trois-Rivières and Cap-de-la-Madeleine, for the transportation of household goods on behalf of \"Les Meubles Maskinongé Inc.\" requests that the following additional right be added to said clause e: (1) When providing the service described in the above-mentioned clause, the holder shall also be authorized to transport household goods utilizing the trailers belonging to and leased from Les Meubles Maskinongé Inc., said trailers having been registered in the Province by said shipper and with the Commission by Clément Transport Inc.which shall haul said trailers with its tractors, duly registered in the Province and with the Commission.(2) The service described in the above additional right shall be provided utilizing the trailers belonging to and leased to Clément Transport Inc.by Les Meubles Maskinongé Inc., as authorized by such permit, which was issued to the latter by the Commission on July 30, 1973.The applicant requests from the Québec Transport Commission the right to provide, under the prescribed conditions, the following transport service: Class: Restricted trucking - haulaway -Service : Haulaway transport to haul the trailers (empty or loaded) of the joint applicant, Kingsway Freight Lines Ltd., which shall operate as carrier; according to all the clauses of the carrier's permanent permit, bearing number 17376-V. 3640 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Rôle M-1772 5334-V D-l-TF SOULANGES CARTAGE & EQUIPMENT CO.LTD.7150 Hochelaga, Montreal.P.Que.H1N 1Y7 Rôle M-1773 8448-V D-l-TF GLENGARRY TRANSPORT (QUÉBECi LTÉE, St-Zotique, P.Que.Augmentation de $1.50 de l'heure sur camion ordinaire et $2.50 l'heure pour tracteurs remorques et fardiers, sur nos taux antérieurs.Fixations de taux pour remorques à chevalets et remorques auto-commandes.Fixation de taux pour transport de container.Fixation de taux à la tonne sur transport de ciment précontraint par remorques ordinaires.Augmentation de Wé à 20é du mille pour taux de transport au mille sur nos taux antérieurs.Augmentation sur taux antérieurs du 1er décembre 1972 pour transport de sel.Négocié avec expéditeur.Demande de taux pour le transport de panneaux agglomérés pour le compte de Sogefor Ltée de Lac-des-nes a tous les endroits situés dans un rayon de 300 milles dudit endroit, dans la rpovince de Québec comme suit: $0.59 le mille aller-retour pour le premier 40.000lbs de charge; $0.62 le cent livres pour l'excédent de 40.000 lbs.Ce service pouvant être effectué en vertu de la clause « L » du permis No 8448-V au nom de Glengarry Transport (Québec) Ltée St-Zotique, P.Q.Increase of $1.50 per hour on standard trucks and $2.50 per hour on tractor trailers and floats, over our former rates.Rate 6xation on rack-equipped trailers and self-powered trailers.Fixation of rates for container transportation.Fixation of rates per ton for the transportation of prestreased concrete by self-powered trailers.Increase of 10< to 20i per mile on our former per-mile transport rates.Increase on our former rates dating from December 1st 1972, for the transportation of salt.Negotiated with shipper.Application for rates applying to the transport of fibreboard on behalf of Sogefor Ltée, from Lao-des-Iles to all points located within a radius of 300 miles from said point, in the Province of Québec, as follows: $0.59 per mile, round trip, for the first 40,000 lbs; $0.62 for each one hundred pounds in excess of 40,000 lbs.Said service to be provided under clause \"L\" of permit No.8448-V, on behalf of Glengarry Transport (Québec) Ltée, St.Zotique, Québec.Rôle M-1774 30006-D-13-TF NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC., P.O.Box 184, Buffalo.N.Y.14221.Adresse au Québec Address in Québec : NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC., a/s Me Guy Parenteau, 1156 ouest, boul.Dorchester, Suite 3504, Montréal, P.Que.Demande de fixation de tarif: Supplément 21 au tarif 261-C (Marchandises générales) : Item 11850-C (Addition): Tarif 290-A (Aéro Fret) : (Augmentation et réduction) : Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter lesdites révisions déposées à la Commission des transports du Québec.Application for fixation of Tariff : Supplement 21 to Tariff 261-C (General Commodity Tariff) : Item 11850-C (Addition): Tariff 290-A (Air Freight): (Increase and Reduction) : For further information, please consult said revisions, which have been filed with the Québec Transport Commission.Rôle M-1775 30007-D-6-TF SOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE, 1307 Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga.30309 Adresse au Québec Address in Québec: SOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE, a/s Me Guy Parenteau, suite 3504, 1155 boul.Dorchester, Montréal, P.Que.Supplément 17 au taux fixe applicable à une seule espèce de marchandise, tarif 159-L, MF-ICC 1724, s'appliquant entre des localités du Sud des Etats-Unis, d'une part, et des endroits de la province de Québec, Canada, d'autre part.Modification des dispositions administratives - aucun changement de taux.Etablir un taux de marchandises réduit s'appliquant aux TOPS, à la laine, de Clarks-ville.Va., à Montréal.Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter lesdits suppléments déposés à la Commission des transports du Québec.Supplément 13 au taux fixe applicable à une seule espèce de marchandise, tarif 519-B, MF-ICC 1725, s'appliquant entre des localités du Sud des Etats-Unis, d'une part, et des endroits de la province de Québec, Canada, d'autre part, le transport étant effectué par des routiers participants aux séries du tarif 619 de Southern Motor Carriers Rate Conference, Tarif 140-B, MF-ICC 1711.Modification des dispositions administratives - aucun changement de taux.Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter lesdits suppléments déposés à la Commission des transports du Québec.Supplement 17 to through one factor specific commodity rate Tariff 159-L.MF-ICC 1724, applying between points in Southern United States, on the one hand, and points in the Province of Québec, Canada on the other hand.Modification of governing provisions - no change in rates.Establish reduced commodity rate on TOPS, wool, from Clarksville, Va.to Montreal.For furtjier information, please refer to the supplement filed with the Québec Transport Commission.Supplement 13 to through one factor class rate Tariff 519TB.MF-ICC 1725, applying between points in Southern United States on the one hand, and points in the Province of Québec, Canada on the other hand, via carriers shown as Participants in Tariff 619 series in Southern Motor Carriers Rate Conference Tariff 140-B, MF-ICC 1711.Modification of governing provisions - no change in rates.For additional information, refer to supplement filed with the Québec Transport Commission. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3641 Rôle M-1777 30003-D-26-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC., Edifice Girardin, suite 400, 1259, rue Berri, Montréal 132, P.Q.H2L 4C7 Demande de fixation de taux: Tarif 1001-C: Tenant compte d'additions et de diverses augmentations de frais pour tes services connexes et d'une augmentation de 7-7H% des taux de transport.Augmentation similaire accordée MCS-382, Re: Canadian Household Goods Carriers' Tariff Bureau Association.Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter les demandes déposées à la Commission des transports du Québec.Application for fixation of rates: Tariff 1001-C: Reflecting additions and various increases in charges for ancillary services and 7-7H% increase in transportation rates.Similar increase granted MCS-382.Re: Canadian Household Goods Carriers' Tariff Bureau Association.Note: For further informations, see application filed with the Québec Transport Commission.Rôle M-1778 30003-D-27-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC., Edifice Girardin, suite 400.1259, rue Berri, Montréal 132, P.Q., H2L 4C7 Demande de fixation de taux: Tarif 30: Item 3860.Augmentations.Additions.Notes: Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter les demandes déposées à la Commission des transports du Québec.Application for fixation of rates: Tariff 30: Item: 3860: Increases.Additions.Note: For further information, see applications filed with the Québec Transport Commission.Rôle M-1779 30003-D-28-TF BUREAU DES TARIFS DU QUÉBEC INC., Edifice Girardin, suite 400, 1259, rue Berri.Montréal 132, P.Q.H2L 4C7 Demande de fixation de taux : Supplément d'ordre général No 36.Re: Augmentation de / ou à Hull 12% applicable pour taux de classe, d'espèces et minimum.Augmentation similaire accordée, MCR-715-TF pour Ottawa.(Re: Canadian Transport Tariff Bureau Association).Note: Pour renseignements supplémentaires, veuillez consulter les demandes déposées à la Commission des transports du Québec.Application for fixation of rates: Blanket Supplement No.36.Re: Increase from / or to Hull 12% applicable on class commodity rates and minimum.Similar Increase granted MCR-715-TF for Ottawa.(Re: Canadian Transport Tariff Bureau Association).Note: For further information, see application filed with the Québec Transport Commission.Rôle M-1780 40012-D-l-TF ASSOCIATION DES CAMIONNEURS DU COMTÉ DE LAPRAIRIE INC., Pour les requérants mentionnés dans l'annexe a / for: the applicants mentioned in schedule a, 864, rue Deslauriers, Laprairie, P.Que.L'Association des Camionneurs du Comté de Laprairie Inc.demande au nom des requérants l'autorisation d'augmenter de 5% les taux antérieurement déposés à la Commission des transports du Québec pour: 1.Le transport de briques de Laprairie à ailleurs dans ia province de Québec pour le compte de Domtar Construction Materials Ltd.2.Le transport de briques de Laprairie à ailleurs dans la province de Québec pour le compte de la Briqueterie St-Laurent, Ltée.L'Association des Camionneurs du comté de Laprairie Inc.requests, on behalf of the applicants, the authorization to increase by 5% the rates previously filed with the Québec Transport Commission for: 1.The transportation of bricks from Laprairie to any point in the Province of Québec on behalf of Domtar Construction Materials Ltd.2.The transportation of bricks from Laprairie to any point in the Province of Quebec, on behalf of Briqueterie St-Laurent, Ltée.Rôle M-1781 23769-V-D-l ROGER THIBAULT, 565, Thomas, St-Amable, P.Québec, Cté Verchères, La partie requérante demande à la Commission le droit d'effectuer le transport suivant: Classe: Transport restreint-service local-contrat-Service: De Beloeil à tous les endroits situés dans un rayon de 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de commandes de pharmacie, pour le compte de Michel Lapierre.The applicant requests from the Commission the right to operate the following transport: Class: Restricted trucking - local service -contract -Service : From Beloeil to all points located within a radius of 5 miles from the limits of said Town, for the transportation of drugstore orders, on behalf of Michel Lapierre.Rôle M-1782 22963-V-D-l CLARK, WAYNE, 361, rue Argenteuil, Lachute, Québec.Requérant / Applicant, 659-V-D-6 SMITH TRANSPORT CO.LTD., 10.755, Côte de Liesse Road, Dorval, P.Québec.Requérant conjoint Joint applicant.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant : Classe: Transport restreint - remorquage -Service : Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant conjoint: Smith Transport Co.Ltd., qui agira comme roulier; en vertu des clauses g,j, et g du permis permanent du roulier portant le numéro 659-V.The applicant requests from the Québec Transport Commission the right to provide, under the prescribed contidions, the following transport service: Class : Restricted trucking - haulaway -Service : Haulaway transport to haul the trailers (empty or loaded) belonging to the joint applicant.Smith Transport Co.Ltd, which shall operate as carrier; according to clauses g, j and q of the carrier's permanent permit bearing number 659-V. 3642 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, Mi, Vol.106, No.SO Rôle M-1783 M-2050T2-D-1 DUVAL, GERMAIN Vendeur/Vendor et / and M-205534, NEILSON, IVAN Acheteur / Purchaser Rôle M-1784 M-201371 TREMBLAY, JEAN-MARIE Vendeur / Vendor et / and M-205714 LEFEBVRE, ROGER Acheteur / Purchaser Rôle M-1785 M-202812 CLOUTIER, ARMAND Vendeur / Vendor et / and M-205720 BEAUDET, RENE Acheteur / Purchaser Rôle M-1786 M-203181 ARCHAMBAULT, RICHARD Vendeur / Vendor et / and M-205721 BOULANGER, ANDRÉ Acheteur / Purchaser Rôle M-1787 M-203512 TSAROUHAS, TOULA Vendeur / Vendor et / and M-205713 SAPOUNAKIS, PANAGIOTIS Acheteur / Purchaser Rôle M-1788 M-205586 FARRESE, FRANK Vendeur / Vendor et/and M-205587 BERGERON, BERNARD Acheteur / Purchaser Rôle M-1789 M-203104 FORGET, OMER Vendeur / Vendor et / and M-205577 CROISETIERS, NORMAND Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Duval.Germain demande à la Commission de transférer à: Neilson, Ivan, 47, Dalton, Waterloo, l'attestation numéro M-205012 D-l qu'il détient, pour desservir la région de Waterloo (063906 VT).Transfer of the ownership of a transporta tion service (sale of taxi).Duval Germain requests the Commission to transler to: Neilson Ivan, 47 Dalton, Waterloo, his certificate number M-205012 D-l to serve the region of Waterloo (063906 VT).Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Tremblay, Jean-Marie demande à la Commission de transférer à: Lefebvre, Roger, 6890, Louis-Hébert, Montréal, l'attestation numéro M-201371 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Tremblay Jean Marie requests the Commission to transfer to: Lefebvre Roger, 6890 Louis-Hébert, Montréal.his certificate number M-201371, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Cloutier, Armand demande à la Commission de transférer à: Beaudet, René, 6700, Des Erables, Montréal, l'attestation numéro M-202812 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Cloutier Armand requests the Commission to transfer to: Beaudet René, 5700 Des Erables, Montreal, his certificate number M-202812, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Archambault, Richard demande à la Commission de transférer à: Boulanger, André, 6050, Des Gro-seillers, Anjou, l'attestation numéro M-203181 qu'il détient, pour desservir l'agglomération Â-ll, Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Archambault, Richard requests the Commission to transfer to: Boulanger, André, 6050 Des Groseillers, Anjou, his certificate number M-203181, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Tsarouhas, Toula demande à la Commission de transférer à: Sapounakis, Panagiotis, 7705, L'Acadie, app.901.Montréal, l'attestation numéro M-2C3512 qu'il détient, pour desservir l'agglomération Â-ll, Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Tsarouhas, Toula requests the Commission to transfer to: Sapounakis, Panagiotis, 7705 L'Acadie, Apt.901, Montreal, his certificate number M-203512, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Farrese, Frank demande à la Commission de transférer à: Bergeron, Bernard, 1002, St-George, Longueuil, l'attestation numéro M-205686 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-6 Est de Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Farrese, Frank, requests the Commission to transfer to: Bergeron, Bernard, 1002 St.George, Longueuil, his certificate number M-205586, to serve conglomeration A-5, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Forget.Orner demande à la Commission de transférer à: Croisetiers, Normand, 94, St-Michel, Lac Nominingue, l'attestation numéro M-2031O4 qu'il détient, pour desservir la région, de Nominingue (Lac Nominingue 077620 SD).Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Forget Omer requests the Commission to transfer to : Croisetiers.Normand, 94 St.Michel, Lac Nominingue, his certificate number M-203104, to serve the region of Nominingue (Lac Nominingue 077620 SD). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3643 Rôle M-1790 M-203287 BÉLANGER, A.-ÉMU.K.Vendeur / Vendor et / and M-2039M-D-9 ALOUETTE ENTREPRISE INC., Acheteur / Purchaser Rôle M-1791 M-200009 MARTIN, ROMÉO Vendeur/Vendor et / and M-204475-D-3 SINCH, JASWANT Acheteur / Purchaser Rôle M-1792 M-205349 CASTILLOUX, FRANK Vendeur/Vendor et / and M-205639 TURPIN, GAÉTAN Acheteur / Purchaser Rôle M-1793 M-201573 AYOTTE, FERNAND Vendeur/Vendor et/and M-205692 DUMOUCHEL, LÉO-PAUL Acheteur / Purchaser Rôle M-1794 M-202687 JONES, MARCEL Vendeur / Vendor et / and M-205663 CRANDMAISON, DIANE Acheteur / Purchaser Rôle M-1795 M-201638 BLEAU.LUCIEN Vendeur/Vendor et / and M-205645 PARENT, JEAN-GUY Acheteur / Purchaser Rôle M-1796 M-203076 ENFEDAQUE, THOMAS Vendeur/Vendor et / and M-202230-D-3 SICILIANO, FRANCO Acheteur / Purchaser Rôle M-1797 M-203055 BERNAIS OVILA Vendeur / Vendor et / and M-202892-D-2 BASTARACHE, ROLLAND Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Bélanger, A.Emile demande à la Commission de transférer à: Alouette Entreprise Inc.5134 Coolbrook.Montréal, l'attestation numéro M-203287 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll.Montréal.^ Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Bélanger A.Emile requests the Commission to transfer to: Alouette Entreprise Inc.5134 Coolbrook.Montreal, his certificate number M-203287, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Martin, Roméo demande à la Commission de transférer à: Singh, Jaswant, 2192.Lapierre.LaSalle, l'attestation numéro M-200009 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal._ Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Martin, Roméo requesti the Commission to transfer to: Singh, Jaswant, 2192 Lapierre.LaSalle.his certificate number M-200009.to serve conglomeration A-12.West of Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Castilloux, Frank demande à la Commission de transférer à: Turpin, Gaétan, 135, Fraser, Thurso, l'attestation numéro M-206349 qu'il détient, pour desservir la région de Thurso (077612 _ Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Castilloux, Frank requests the Commission to transfer to: Turpin, Gaétan, 135 Fraser, Thurso, his certificate number M-205349, to serve the region of Thurso (077512 VT).Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Ayotte, Fernand demande à la Commission de transférer à: Dumouchel, Léo Paul, 2795, Carignan app.3, Montréal.l'attestation numéro M-201573 qu'il détient, pour desservir l'agglomération Â-ll, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Jones, Marcel demande à la Commission de transférer à: Grandmaison, Diane, 6823 Louis-Hébert, Montréal, l'attestation numéro M-202687 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Bleau.Lucien demande à la Commission de transférer à: Parent, Jean-Guy, 1627 St-Hubert, app.4, Montréal, l'attestation numéro M-201638 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll.Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Enfedaque.Thomas demande à la Commission de transférer à : Siciliano, Franco, 288 boulevard Youville, Montréal, l'attestation numéro M-203076 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll, Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Ayotte, Fernand requests the Commission to transfer to: Dumouchel, Léo Paul, 2795 Carignan, Apt-Montreal, hia certificate number M-201573, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Jones, Marcel requests the Commission to transfer to: Grandmaison, Diane, 6823 Louis-Hébert, Montreal, his certificate number M-202687.to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Bleau, Lucien requests the Commission to transfer to: Parent, Jean-Guy, 1627 St.Hubert, Apt.4, Montreal, his certificate number M-201638, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Enfedaque, Thomas requests the Commission to transfer to: Siciliano, Franco, 288 Youville Blvd., Montreal, his certificate number M-203076, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Bernais.Ovila demande à la Commission de transférer à: Bastarache.Rolland.86 Merry Sud.Magog.l'attestation numéro M-203066 qu'il détient pour desservir la région de Magog comprenant les municipalités de Magog.053734 CT et 053738 C, Orford 053614 GT, Omerville 053736 V.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Bernais, Ovila requests the Commission to transfer to: Bastarache, Rolland, 85 Merry Sud, Magog, certificate number M-203055, which he holds, to serve the region of Magog, comprisû}g the municipalities of Magog, 053734 CT and 053738 C.Orford 053614, CT.Omerville 053736 V. 3644 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 Rôle M-1798 M-200518 MORIN, ARTHUR Vendeur/Vendor et / and M-205603 PORTUGAIS, AIMÉ Acheteur / Purchaser Rôle M-1799 M-201596-D-1 LANTHIER EMILE LTD.Vendeur / Vendor et / and M-205655 LEBRUN,FELTON Acheteur / Purchaser Rôle M-1800 M-200567 DAN1EL1 dis, john Vendeur / Purchaser et / and M-205599 ELEFTERIOS, MENTRAS Acheteur / Purchaser Rôle M-1801 M-204201 LAHAIE, GERMAINE Vendeuse / Vendor et / and M-205725 EDERY, SALOMON Acheteur / Purchaser Rôle M-1802 M-202397 COTZAMANOGLOU ARTEMIS Vendeuse / Vendor et / and M-201485-D-4 TSATSAKIS, HARRY Acheteur / Purchaser Rôle M-1803 M-203562 DERDÊRIAN, HAROUNTOUN Vendeur / Vendor et / and M-205717 FARSHID, KARIMIAN Acheteur / Purchaser Rôle M-1804 M-205723 ST-ONGE, ROBERT Vendeur / Vendor et / and M-205722 LACOSTE, FERNAND Acheteur / Purchaser Rôle M-1805 M-203829 LIPARI, ANTONIO Vendeur / Vendor et / and M-205726 CARDONE, DOMINICO Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Morin, Arthur demande à la Commission de transférer à: Portugais, Aimé, 6868 Ouest, Sherbrooke app.61A, Montréal, l'attestation numéro M-200518 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12, Ouest de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lanthier, Emile Ltd.demande à la Commission l'autorisation de céder A: Lebrun.Felton, 1250, Laird, app.4, Ville Mont-Royal, la propriété du système de transport et de lui transférer l'attestation numéro M-201596 D-l qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).DanieJidis, John demande à la Commission de transférer à: Elefterios, Mentras, 975, Jarry, app.4, Montréal, l'attestation numéro M-200567 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lahaie, Germaine demande à la Commission de transférer à: Edery, Salomon, 2835,Goyer, app.17, Montréal, l'attestation numéro M-204201 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi), Cotzamanoglou, Artemis demande à la Commission de transférer à: Tsatsakis, Harry, 2662, Place Joseph-Casavant, Montréal, l'attestation numéro M-202397 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll, Montréal.Cession de la propriété de système de transport (vente de taxi).Derdérian Haroun-toun demande à la Commission de transférer à: Farshid Karimian, 4998 ouest, Maison-neuve, app.1215, Montréal, l'attestation numéro M-203562 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).St-Onge.Robert demande à la Commission de transférer à: Lacoste, Fernand, 9642, du Buisson, Montréal, l'attestaton numéro M-205723 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lipari Antonio demande à la Commission de transférer à: Cardone, Dominico, 7442, St-Gérard, Montréal, l'attestation numéro M-203829 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Morin, Arthur requests the Commission to transfer to: Portugais, Aimé, 6878 Sherbrooke West, Apt.51A, Montreal, his certificate number M-200518, to serve conglomeration A-12, West of Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Lanthier, Emile Ltd.requests from the Commission the authorization to transfer to: Lebrun, Felton, 1250 Laird, Apt.4, Town of Mount Royal, the ownership of the transportation service and requests that the Commission transfer to the latter certificate number M-201596 D-l, wruch he holds, to serve conglomeration A-ll.Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Danielidis, John requests the Commission to transfer to: Elefterios, Mentras, 975 Jarry, Apt.4, Montreal, his certificate number M-200567, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Lahaie, Germaine requests the Commission to transfer to: Edery, Salomon, 2835 Goyer, Apt.17, Montreal, his certificate number M-204201, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Cotzamanoglou, Artemis requests the Commission to transfer to: Tsatsakis, Harry, 2652 Place Joseph-Casavant, Montreal, his certificate number M-202379, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Derdérian Harountoun requests the Commission to transfer to: Farshid, Karimian.4998 Maisonneuve W.Apt.1216, Montreal, his certificate number M-203562, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of ownership of a transportation service (sale of taxi).St-Onge, Robert requests the Commission to transfer to: Lacoste, Fernand, 9642 Du Buisson, Montréal, his certificate number M-205723, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of ownership of a transportation service (sale of taxi).Lipari Antonio requests the Commission to transfer to: Cardone, Dominico, 7442 St-Gérard, Montreal, his certificate number M-203829, to serve conglomeration A-ll, Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3645 Rôle M-1806 M-204434 CARDOSO, LUIS Vendeur/Vendor et / and M-205607 RIBEIRO, SÉRAFIM Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Carduso, Luis demande à la Commission de transférer à: Ribeiro.Sérafim, 2710, Barclay, app.1, Montréal, l'attestation numéro M-204434 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of ownership of a transportation service (sale of taxi).Garduso, Luis requests the Commission to transfer to: Ribeiro, Sérafim.2710 Barclay.Apt.1.Montreal, his certificate number M-204434, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Rôle M-1807 M-12958-V-D-1 DIRECT MOTOR EXPRESS QUEBEC LIMITED, 2800.avenue André.Dorval, Pointe-Claire.(Dorval).740.Que.Rôle M-1808 23778-V-D-l LE COMPTOIR AGRICOLE ST-ROCH INC., CP.180, boul.Rémi-Henri.St-Roch de l'Achigan.P.Que.J0K 3H0 Rôle M-1809 23772-V-D-l ROSAIRE NÉRON, 6990.9e avenue, Rosemont, Montréal.P.Québec.Requérant / Applicant, 8123-V-D-5 JOHN N.BROCKLESBY TRANSPORT LTD., 11,175.boul.Parkway, Ville d'Anjou, P.Québec.Requérant conjoint Joint Applicant.Rôle M-1810 13349-V-D-l-TF R.A M.SERVICES INC., 1501.rue Marlborough, Montréal, P.Q.Modification de clause: La partie requérante demande que la clause ff suivante: ff) Transport général - longue distance -route restreinte - ff) De St-Etienne, St-Louis-de-Gonzague, St-Stanislas-de-Kostka et Ste-Barbe à Montréal et retour.soit remplacée par la suivante: ff) Transport général - longue distance -route - ff) De St-Etienne, St-Louis-de-Gonzague, St-Stanislas-de-Kostka et Ste-Barbe à Montréal et retour.Droit additionnel : Le droit de transbordement au terminus de base de Valleyfield est restremt au transport de marchandises dans des remorques appartenant à des transporteurs américains, détenteurs de permis de l'Interstate Commerce Commission et livrées à Valleyfield en vertu de leur service régulier de ferroutage (piggyback).La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir le droit de donner le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service: De Montréal à destination des comtés suivants: Terrebonne, Deux-Montagnes, Ar-genteuil, l'Assomption, Montcalm, Joliette, Label le.Gatineau et Papineau; pour le transport de moulée en sacs ou à l'état lâche, destinée aux clients de Master Feed (Division de Maple Leaf Mills), par camions spécialement agencés à cette fin et munis d'une souffleuse.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - remorquage -Service: Transport par remorquage pour tirer les remorques vides ou remplies du requérant-conjoint: John N.Brocklesby Transport Ltd.qui agira comme roulier; en vertu de toutes les clauses du permis permanent du roulier portant le numéro 8123-V.Demandons une augmentation de 10% sur nos taux actuels due à une hausse du coût de la main-d'oeuvre et des produits pétroliers.Modification of clause: The applicant requests that the following clause ff: (ff) General trucking - long distance -restricted route - (ff) From St.Etienne, St.Louis de-Gon-zague, St.Stanislas-de-Kostka and Ste.Barbe to Montreal, and return, be replaced by the following: (ff) General trucking - long distance -route - (ff) From St.Etienne, St.Louis-de-Gon-zague, St.Stanislas-de-Kostka and Ste.Barbe to Montreal, and return.Additional right: The right of transhipment at the base terminal in Valleyfield shall be restricted to the transportation of goods in trailers belonging to American Carriers holding permits from the Interstate Commerce Commission, such goods to be delivered in Valleyfield, by their regular piggyback service.The applicant requests from the Québec Transport Commission the right to provide the following transport Bervice: Class: Restricted trucking - long distance -restricted route -Service : From Montreal, to points of destination in the following Counties: Terrebonne, Two Mountains.Argenteuil, l'Assomption, Montcalm, Joliette.Labelle, Gatineau and Papineau, for the transportation of feed (meal) in bags or in bulk, destined to the customers of Master Feed (Division of Maple Leaf Mills), by trucks specially designed for this purpose and equipped with blowers.The applicant requests from the Québec Transport Commission the right to provide, according to the prescribed conditions, the following transport service: Class: Restricted trucking - haulaway -Service: Haulaway service to haul the trailers, (empty or loaded) belonging to the joint applicant, John N.Brocklesby Transport Ltd., which shall operate as carrier; according to all the clauses of the latter's permanent permit bearing number 8123-V.We request an increase of 10% on our present rates, owing to the increased cost of labour and of petroleum products. 3646 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971,, Vol.106, No.SO Rôle M-1811 22303-V-D-l-TF PAUL-EMILE FAUBERT TRANSPORT, 1165, boul.Provencher, app.4 Brossard, P.Q.Rôle M-1812 9047-V-D-l-TF GILBERT TRANSPORT REC'D.P.O.Box 45, Arundel, P.Que.Rôle M-1813 M-13508-V-D-1-TF BLAIS EXPRESS INC., 856, Larocque, Sherbrooke, P.Que.Je demande à la Commission d'approuver l'amendement de mes taux.Anciens tarifs $1.76 - 1er colis et 2e colis $1.00-3e colis $0.25-pour chaque carton après les trois premiers.Nouveaux tarifs $2.25- 1er et 2e colis $1.50-3e colis $0.25-pour chaque colis après les trois premiers.Modification de taux de Kilmar (Québec), à Montréal (Québec), et retour.(Augmentation de 9%).I request the Commission to approve the modification of my rates.Former tariffs $1.75- 1st and 2nd parcels $1.00-3rd parcel $0.25 - for each additional parcel 3fter the first three.New tariffs $2.25 - 1st and 2nd parcels $1.50-3rd parcel $0.25- for each additional parcel after the first three.Rate change from Kilmar P.Q.to Montreal, P.Q.and return.(Increase of 9%).Demande d'augmentation de taux concernant la livraison de colis, transport général et déménagement pour la Cité de Sherbrooke tarif No 5 - supplément Mo 2.Application for increase in rates applicable to the delivery of parcels, general trucking and moving, for the City of Sherbrooke -Tariff No.6 - Supplement No.2.Tarif Tarif actuel proposé Prêtent Proposed Tariff Tariff L'heure / Per hour Pour un colis / For one parcel.^.$0.50 $0.75 Chaque colis additionnel/Each additional parcel.0.15 0.25 Service de transport, comprenant camion et chauffeur / Transport service, including truck and driver.$ 5.50 $ 6.50 Camion d'une tonne roues doubles avec chauffeur / One-ton truck, double wheels with driver.5.60 7.00 Camion de 2 à 4 tonnes et chauffeur /Z-to-4-ton truck and driver.7.00 8.50 Camion de 5 tonnes et chauffeur / 6-ton truck and driver.8.00 9.50 Camion tracteur 6 roues/Tractor-truck 6 wheels.7.00 12.00 Aides marchandises générales chaque / Helpers, commodities, each.3.00 4.00 ABC Service d'un fourgon, chauffeur seulement / One-van service, driver only: taux proposé / proposed rate.$12.00 $14.50 $17.00 taux actuel / present rate.10.00 12.00 14.00 Service d'une semi-remorque, chauffeur seulement / One semi-trailer service, driver only: taux proposé / proposed rate.13.00 15.50 18.00 taux actuel / present rate.11.00 13.00 16.00 Service d'un fourgon, chauffeur et 1 aide / One-van service, driver and 1 helper: taux proposé / proposed rale.17.00 22.00 27.00 taux actuel / present rate.14.00 18.00 22.00 Service d'une semi-remorque chauffeur et 1 aide / One semitrailer service, driver and 1 helper: taux proposé/ proposed rate.18.00 23.00 28.00 taux actuel / present rate.15.00 19.00 23.00 Service d'un fourgon chauffeur et 2 aides / One-van service, driver and 2 helpers: t aux proposé / proposed rate.22.00 29.50 37.00 taux actuel / present rate.18.00 24.00 30.00 Service d'une semi-remorque, chauffeur et 2 aides / One semitrailer service, driver and Z helpers: taux proposé / proposed rate.23.00 30.50 38.00 taux actuel / present rate.19.00 25.00 31.00 Aides additionnels, chaque / Each additional helpers: taux actuel / present rate.4.00 6.00 8.00 Aides additionnels, chaque / Each additional helpers: taux proposé / proposed rate.5.00 7.60 10.00 Déménagement avec piaao extra de / Moving including piano.$10.00 $12.00 surplus par étage / exira for each floor.3.00 5.00 Déménagement avec congélateur extra / Moving including freezer, extra 5.00 8.00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3647 Rôle M-1814 3564-A-D-l PURCELL, ALICE, (Mme) 395, rue Lamarre, App.6, Longueuil, P.Que.Rôle M-1815 714-A-D-l LES AUTOBUS _ RICHELIEU LTÉE, 481, rue St-Jacques, Napierville, (Napierville), P.Que.Rôle M-1816 3566-A-D-l MUSKOKA BUS LINES LIMITED, 23 Shier Street, Bracebridge, Ontario.Rôle M 1-17 M-504013-D-1 DUCHARME, GABRIEL, 345, rue Meunier, Duvernay, Ville de Laval, P.Que.Rôle M-1818 M-505407-D-1 LABRIE, ARMAND, 134, rue Dubé, Laurierville, Comté Mégantic, P.Q.Déménagement à la pièce / Moving, separate items: Piano bas - orgue / Low piano - organ.Piano droit - moyen / Upright piano - medium-size.Piano droit gros-petit a queue / Large upright or small grand piano Piano à queue de concert / Concert grand piano.Charge additionnelle par étage / Extra charge per storey.Congélateur couché-debout / Freezer horizontal-vertical.Poêle ou réfrigérateur / Kitchen range or refrigerator.Laveuse ou sécheuse / Washer or dryer.Charge additionnelle par étage / Extra charge per storey.Service de palan avec le déménagement / Hoisting-gear service furnished with moping service.Service de palan sans le déménagement.' Hoisting-gear service furnished apart from moving service.20.00\t25.00 25.00\t30.00 35.00\t40.00 46.00\t50.00 6.00\t6.00 16.00\t20.00 10.00\t12.00 10.00\t12.00 3.00\t3.00 15.00\t20.00 35.00\t40.00 Agir comme courtier en transport pour passagers originant de Longueuil à destination de tout point situé dans la Province de Québec et aux frontières de: « Québec - Etats-Unis - Québec - Ontario et Québec-Nouveau-Brunswick, et retour.» La requérante qui opère divers services en vertu de son permis demande l'autorisation de donner le service additionnel suivant : Classe de permis: Service d'autobus.Service : Voyages à charte-partie originant des municipalités desservies en vertu de son permis à destination des frontières : Québec - Ontario - Québec - Nouveau-Brunswick et Québec - Etats-Unis, et retour.La partie requérante désire transporter des groupes de personnes, avec leurs bagages, à partir de la ville de Gravenhurst et de cette partie de la ville de Bracebridge connue autrefois sous le nom de canton de Draper, ainsi que de ces parties du canton de Mus-koka Lakes autrefois connues sous le nom de cantons de Wood et Muskoka, tous ces endroits étant dans le district municipal de Muskoka, province de l'Ontario, a destination de localités de la province de Québec, à l'occasion de voyages spéc:aux ou a.charte-partie.Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder au requérant acheteur: Crémont.Jean, 370, rue Meunier.Duvernay.Ville de Laval.P.Que.(M-505560 D-l).la propriété du système de transport de camionnage en vrac suivant: Attestation No M-504013 D-l qu'il détient pour le camion suivant : Dodge 1969 Série No T8L2J30964 F-297-201 1973 Cession de la propriété du système de transport (vente).La partie requérante demande l'autorisation de céder au requérant acheteur: Labrie.Jacques, 134, rue Dubé, Laurier-ville, comté de Mégantic, P.Q.(M-505644 D-l), la propriété du système de transport de camionnage en vrac suivant : Attestation No M-606407 D-l qu'il détient pour le camion suivant: Chevrolet 1968 Série No CE6381112839 F-180-660 1973 To operate as transport broker for passengers leaving from Longueuil and destined to any point located in the Province of Québec and to the following borders : \"Québec - United States - Québec - Ontario and Québec - New Brunswick, and return.\" The applicant, which operates various services according to its permit, requests the authorization to provide the following additional service: Class of permit: Bus.Service : Charter trips originating from the municipalities served according to said permit and proceeding to the following borders: Québec - Ontario - Québec - New Brunswick, and Québec - United States, and return.The applicant wishes to transport groups of persons, together with their baggage, from the Town of Gravenhurst and that part of the Town of Bracebridge, formerly known as the Township of Draper, and those portions of the Township of Muskoka Lakes that were formerly known as the Townships of Wood and Muskoka.all in the District Municipality of Muskoka.in the Province of Ontario, to points in the Province of Québec by way of special charter trips.Transfer of ownership of transport service (sale).The applicant requests authorization to transfer to the applicant purchaser: Crémont, Jean, 370 Meunier Street, Duvernay, City of Laval, Québec, (M-605560 D-l), the ownership of the following bulk trucking service: Certificate No.M-504013 D-l, which he holds for the following truck : 1969 \"Dodge\" Serial No.T8L2J30964 F-297-201 1973 Transfer of ownership of transportation service (sale).The applicant requests authorization to transfer to the applicant purchaser: Labrie, Jacques, 134 Dubé Street, Laurierville, County of Mégantic, P.Q.(M-505644 D-l).the ownership of the following bulk trucking service : Certificate No.M-505407 D-l which he holds for the following truck : 1968 \"Chevrolet\" Serial No.CE6381112839 F-180-650 1973 3648 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18.1974, Vol.106, No.30 Rôle M-1819 M-206541 LES HÉRITIERS DE LA SUCCESSION CLÊTUS alias CLIFFORD CAMPBELL Vendeur / Vendor et / and M-205542 CÔTÉ, ARMAND, Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (décès).Les héritiers de la succession Clétus alias Clifford Campbell, 452, rue King.Granby, P.Q.(M-203046).demande de transférer à Côté, Armand (M-205542) l'attestation numéro M-203046 que détenait le défunt, pour desservir l'agglomération A-33 Granby.Transfer of ownership of transportation service (death).The heirs of the Clétus alias Clifford Campbell estate.452 King Street, Granby, P.Q.(M-203046).request the transfer to Côté, Armand (M-205542) of certificate number M-203046.held by the deceased, to serve conglomeration A-33, Granby.Rôle M-1820 M-204275 CHANTAL, ANTOINE Vendeur / Vendor et / and M-205614 FAZZONE, ANTONIO Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Chantai, Antoine demande à la Commission de transférer à: Fazzone, Antonio, 4685, Buies, St-Léonard, l'attestation numéro M-204275 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-6 Est de Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Chantai.Antoine requests the Commission to transfer to: Fazzone, Antonio, 4685, Buies, St.Léonard, his certificate number M-204276, to serve conglomeration A-5, East of Montreal.Rôle M-1821 M-202347 MOFORIS, PAOLA Vendeur / Vendor et / and M-205719 PERDIOS, ANDREAS Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Moforis, Paola demande à la Commission de transférer à: Perdios, Andréas, 2180, de Salaberry, app.27, Montréal, l'attestation numéro M-202347 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of ownership of a transportation service (sale of taxi).Moforis, Paola requests the Commission to transfer to: Perdios, Andréas, 2180 De Salaberry, Apt.27, Montreal, his certificate number M-202347, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Rôle M-1822 M-205281 BRUNET, PIERRE Vendeur / Vendor et / and M-205146 PRATTAS, STEVE Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Brunet, Pierre demande à la Commission de transférer à: Prattas, Steve, 2375, Montréal Toronto, Boul, Lachine, l'attestation numéro M-205281 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Brunet, Pierre requests the Commission to transfer to: Prattas, Steve, 2375 Montreal Toronto Blvd.Lachine, his certificate number M-205281, to serve conglomeration A-12, West of Montreal.Rôle M-1823 M-201462 TSIRBAS, GEORGE Vendeur / Vendor et / and M-204469-D-2 IMRE, JUHASZ Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Tsirbas, George demande à la Commission de transférer à: Imre.Juhasz, 3210, Forest Hill, app.609, Montréal, l'attestation numéro M-201462 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal._ Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Tsirbas, George requests the Commission to transfer to: Imre, Juhasz, 3210 Forest Hill, Apt.609, Montreal, his certificate number M-201462, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Rôle M-1824 M-200299 GAGNON, JEAN-LOUIS Vendeur / Vendor et / and M-205298-D-11 LES ENTREPRISES J.P.ROY, INC.Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Gagnon, Jean-Louis demande à la Commission de transférer à: Les Entreprises J.P.Roy Inc., 1955, Grenet, St-Laurent, l'attestation numéro M-200299 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Gagnon, Jean-Louis requests the Commission to transfer to: Les Entreprises J.P.Roy Inc., 1955 Grenet, St.Laurent, his certificate number M-200299, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Rôle M-1825 M-204798 FORTIN, EDGAR Vendeur / Vendor et / and M-201620-D-8 FORTIN, RAOUL Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Fortin, Edgar demande à la Commission de transférer à: Fortin, Raoul, 8223, Boyer, Montréal, l'attestation numéro M-204798 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Fortin, Edgar requests the Commission to transfer to: Fortin, Raoul, 8223 Boyer, Montreal, his certificate number M-204798, to serve conglomeration A-ll, Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3649 Rôle M-1826 M-203539-D-2 ETHIER.FERNAND Vendeur / Vendor et/and M-205649 BELZILE, GRATIEN Acheteur / Purchaser Rôle M-1827 M-201105 BLANCHETTE, AIMÉ Vendeur/Vendor et / and M-201106 GAGNON NORMAND Acheteur / Purchaser Rôle M-1828 M-205710 LEMIRE, RAYMOND Vendeur / Vendor et / and M-205589 HAMEL, DENIS Acheteur / Purchaser Rôle M-1829 M-201897 KUN GECZI, ELISABETH Vendeur/Vendor et / and M-205702 FELLEGI, DELSO Acheteur / Purchaser Rôle M-1830 M-205347 EDRAPP, EUGÈNE Vendeur/Vendor et / and M-205620 GAULIN, BLANCHE Acheteur / Purchaser Rôle M-1831 M-206204 COFFIN, ALBERT TERRENCE Vendeur / Vendor et / and M-201683 D-2 MESSIER, SUZANNE Acheteuse / Purchaser Rôle M-1832 M-201216 DESSAILLIERS, JÉRÔME Vendeur / Vendor et / and M-205707 BERGERON, YVON Acheteur / Purchaser Rôle M-1833 M-204646 NADEAU, RENALD Vendeur / Vendor et / and M-205661 ST-PIERRE, JEAN Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Ethier, Fernand demande à la Commission de transférer à: Belzile, Gratien, 4697, Gouin est, Montréal-Nord, l'attestation numéro M-203639 D-2 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Blanchette, Aimé demande à la Commission de transférer à: Gagnon, Normand, 1852, Godin, Ville Laflè-che, P.Q., l'attestation numéro M-201105 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-2 Longueuil.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lemire, Raymond demande à la Commission de transférer à: Hamel, Denis, 2280- 12e Ave Nord, Sherbrooke, l'attestation numéro M-205710 qu'il détient, pour desservir la région de Fleurimont (053604 SD).Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Kun Geczi, Elizabeth demande à la commission de transférer à: Fellegi, Delso, 4378, Wilson Avenue, Montréal, l'attestation numéro M-201897 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Edrapp, Eugène demande à la Commission de transférer à: Gaulin, Blanche, 6674 D'Aragon, Ville Emard, l'attestation numéro M-025347 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Coffin, Albert Terrence demande à la Commission de transférer à: Messier, Suzanne, 115, Ave Brunet, Montréal, l'attestation numéro M-205204 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Dessailliers, Jérôme demande à la Commission de transférer à: Bergeron, Yvon, 315, Desjardins, St-Charles de Mandeville, l'attestation numéro M-201216 qu'il détient, pour desservir la région de St-Charles de Mandeville (064926 SD).Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Nadeau, Renald demande à la Commission de transférer à: St-Pierre, Jean, 87, Place Caron, Ste-Thérèse de Blainville, l'attestation numéro M-204646 qu'il détient, pour desservir la région de Ste-Thérèse (066309 C).Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Ethier, Fernand requests the Commission to transfer to: Belzile, Gratien, 4697 Gouin East, Montreal-North, his certificate number M-203539 D-2, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Blanchette, Aimé requests the Commission to transfer to: Gagnon, Normand, 1852 Godin, Ville Laflè-che.P.Q., his certificate number M-201105, to serve conglomeration A-2, Longueuil.Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Lemire, Raymond requests the Commission to transfer to: Hamel, Denis, 2280 - 12th Ave North, Sherbrooke, his certificate number M-205710.to serve the region of Fleurimont (053604 SD).Transfer of the ownership of a transportation service (sale of taxi).Kun Geczi, Elizabeth requests the Commission to transfer to : Fellegi, Delso 4378 Wilson Avenue, Montreal, her certificate number M-201897, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Edrapp, Eugène requests the Commission to transfer to: Gaulin, Blanche, 6547 D'Aragon, Ville Emard, his certificate number M-025347, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Coffin, Albert Terrence requests the Commission to transfer to: Messier, Suzanne, 115 Brunet Avenue, Montreal, his certificate number M-205204, to serve, conglomeration A-12, West of Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Dessailliers, Jérôme requests the Commission to transfer to: Bergeron, Yvon, 315 Desjardins, St-Charles de Mandeville, his certificate number M-201216, to serve region of Saint-Charles de Mandeville (064926 SD).Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Nadeau, Renald request the Commission to transfer to: St-Pierre, Jean, 87 Place Caron, Ste-Thérèse de Blainville, his certificate number M-204646, to serve region of Ste Thérèse (066309 C). 3650 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 Rôle M-1834 M-204759 LIBERATOSCIOLI, DONATO Vendeur / Vendor et / and M-205532 TEIXEIRA, FELIPE Acheteur / Purchaser Rôle M-1835 M-204760 VEISFELD, ANNIE Vendeur / Vendor et / and M-205694 SHAW MICHAEL (Acheteur / Purchaser Rôle M-1836 M-203889 PRIEUR, GASTON Vendeur / Vendor et / and M-205693 DEGUIRE, DAVID Acheteur / Purchaser Rôle M-1837 M-200376 PELLERIN, RENÉ Vendeur / Vendor et / and M-205545-D-2 POIRIER, RÉJEAN Acheteur / Purchaser Rôle M-1838 M-200427 ROCHON, ROMÉO Vendeur / Vendor et / and M-201509-D-6 GAUTHIER, PIERRE Acheteur / Purchaser Rôle M-1839 M-203749 SIGOUIN, MAURICE Vendeur / Vendor et / and M-205613 ELIOPOULOS, NICOLAS Acheteur / Purchaser Rôle M-1840 M-200041 DALI AN IS, CHRISTOS Vendeur/Vendor et / and M-205683 LOANNOU, DEMETRIOS Acheteur / Purchaser Rôle M-1841 M-203432 MACRAE, DENNIS Vendeur / Vendor et / and M-203256 MARTIAL, JASMIN Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Liberatoscioli, Donato demande à la Commission de transférer à: Teixeira, Felipe, 4344, Clark, Montréal, l'attestation numéro M-204759 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Liberatoscioli, Donato requests the Commission to transfer to: Teixeira, Felipe.4344 Clark, Montreal, his certificate number M-204759, to serve conglomeration A-ll.Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Veisfeld, Annie demande à la Commission de transférer à: Shaw, Michael, 1425, Décarie, app.26, Montréal, l'attestation numéro M-204760 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Veisfeld, Annie requests the Commission to transfer to: Shaw, Michael, 1425 Decarie.Apt.26 Montreal, her certificate number M-204760, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Prieur, Gaston demande à la Commission de transférer à: Deguire, David, 1116, Rawdon.Lasalle, l'attestation numéro M-203889 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Prieur, Gaston requests the Commission to transfer to: Deguire, David, 1116 Rawdon, LaSalle, his certificate number M-203889, to serve conglomeration A-12, West of Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Pellerin, René demande à la Commission de transférer à: Poirier, Réjean, 140, Labonté Longueuil, l'attestation numéro M-200376 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-2 Longueuil Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Pellerin, René requests the Commission to transfer to: Poirier, Réjean, 140 Labonté, Longueuil, his certificate number M-200376, to serve conglomeration A-2, Longueuil.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Rochon, Roméo demande à la Commission de transférer à: Gauthier, Pierre, 4880, Rouen, Montréal, l'attestation numéro M-200427 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Rochon, Roméo requests the Commission to transfer to: Gauthier, Pierre, 4880 Rouen, Montreal, his certificate number M-200427, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Sigouin, Maurice demande à la Commission de transférer à: Eliopoulos, Nicolas, 8203, de l'Epée, Montréal 303, l'attestation numéro M-203749 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal._ Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Sigouin, Maurice requests the Commission to transfer to: Eliopoulos, Nicolas, 8203 de l'Epée, Montreal 303, his certificate number M-203749, to serve conglomeration A-ll.Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Dalianis, Christos demande à la Commission de transférer à: Loannou, Demetrios, 7705, Boul.L'Acadie.app.202, Montréal, l'attestation numéro M-200041 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Dalianis, Christos requests the Commission to transfer to: Loannou, Demetrios, 7705 Blvd.L'Acadie, Apt.202, Montreal, his certificate number M-200041, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).MacRâe, Dennis demande à la Commission de transférer à: Martial, Jasmin, 166, Poplar Drive, Dollard-des-Ormeaux.l'attestation numéro M-203432 qu'il détient pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal.Transfer of the ownership of transformation service (sale of taxi).MacRae, Dennis requests the Commission to transfer to: Martial, Jasmin, 166 Poplar Drive, Dollard-des-Ormeaux, his certificate number M-203432, to serve conglomeration A-12, West of Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3651 Rôle M-1842 M-205454 NOLET, ROGER Vendeur/Vendor et / and M-202719 LACROIX, ROBERT Acheteur / Purchaser Rôle M-1843 M-205316 DUMAIS, ERNEST Vendeur / Vendor et / and M-205592 EMOND, JEAN CLAUDE Acheteur / Purchaser Rôle M-1844 M-204282 DIXON, DONALD ROBERT Vendeur / Vendor et / and M-205715 DRAKOPOULOS, PERIKLIS Acheteur / Purchaser Rôle M-1845 M-204267 D-l PINARD, GASTON Vendeur / Vendor et / and M-205690 D-l VERDON, ROLLAND Acheteur / Purchaser Rôle M-1846 M-205445 TAIBONOULIS, DI MITRA Vendeur/Vendor et / and M-205695 SOTIRIOS, LIMNOS Acheteur / Purchaser Rôle M-1847 M-205356 RUCCOLO, CARMINE Vendeur/Vendor et / and M-20S647 GATTO, GIUSEPPE Acheteur / Purchaser Rôle M-1848 M-204030 TRÉPANIER, RENÉ Vendeur/Vendor et / and M-203622 D-6 LEDUC, LÉO Acheteur / Purchaser Rôle M-1849 M-204861 D-l CONNELLY, ARTHUR Vendeur/Vendor et / and M-205700 TREMBLAY, ROGER Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Nolet, Roger demande à la Commission de transférer à: Lacroix, Robert, 79, St-Charles, St-Jean, l'attestation numéro M-205454 qu'il détient pour desservir l'agglomération A-41 St-Jean.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Dumais, Ernest demande à la Commission de transférer à: Emond, Jean-Claude, 9347, Pie IX, app.5, Montréal, l'attestation numéro M-205316 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Dixon, Donald Robert demande à la Commission de transférer à: Dralopoulos, Periklis, 261, Allard, Dorval, l'attestation numéro M-204282 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-12 Ouest de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Pinard, Gaston demande à la Commission de transférer à: Verdon, Rolland, 7739, Lajeunesse, Montréal, l'attestation numéro M-204267 D-l qu'il détient, pour deservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Taibonoulis, Di-mitra demande à la Commission de transférer à: Sotirios, Limnos, 6066, Notre-Dame, Chomedey, l'attestation numéro M-205445 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Ruccolo, Carmine demande à la Commission de transférer à: Gatto, Giuseppe, 1405, Everett, app.3, Montréal, l'attestation numéro M-205356 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-5 Est de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Trépanier, René ¦ demande à la Commission de transférer à: Leduc, Léo, 250, 6ième Ave.,Ville Ile Perrot, l'attestation numéro M-204030 qu'il détient, pour desservir la région de L'Ile Perrot (06 7206 VT).Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Connelly, Arthur demande à la Commission de transférer à: Tremblay, Roger, 680, Clément, Gatineau, l'attestation numéro M-204861 D-l qu'il détient, pour desservir la région de Gatineau (07 7908 VT).Transfer of the ownership of transformation service (sale of taxi).Nolet, Roger requests the Commission to transfer to : Lacroix, Robert, 79 St-Charles.St-Jean, his certificate number M-205454, to serve conglomeration A-41, St-Jean.Transfer of the ownership of transformation service (sale of taxi).Dumais, Ernest requests the Commission to transfer to: Emond, Jean-Claude, 9347 Pie IX, Apt.5, Montreal, his certificate number M-205316, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxiK Dixon, Donald Robert requests the Commission to transfer to: Dralopoulos, Periklis, 261 Allard, Dorval, his certificate number M-204282, to serve conglomeration A-12, West of Montreal.t Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Pinard, Gaston requests the Commission to transfer to: Verdon, Rolland, 7739 Lajeunesse, Montreal, his certificate number M-204267 D-l, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Taibonoulis, Di-mitra requests the Commission to transfer to: Sotirios, Limnos, 5166 Notre-Dame, Chomedey, his certificate number M-205445, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Ruccolo, Carmine requests the Commission to transfer to: Gatto, Giuseppe, 1405 Everett, Apt.3, Montreal, his certificate number M-206356, to serve conglomeration A-5, East of Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Trépanier, René requests the Commission to transfer to: Leduc.Léo, 250-6th Avenue, Ville Ile Perrot, his certificate number M-204030, to serve region of L'Ile Perrot (06 7206 VT).Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Connelly, Arthur requests the Commission to transfer to: Tremblay, Roger, 680 Clément, Gatineau.his certificate number M-204861 D-l, to serve region of Gatineau (07 7908 VT). 3652 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Rôle M-1850 M-204848 MILONAKOS, GEORGE Vendeur / Vendor et / and M-205728 KOKKALAKIS, NICOLAOS Acheteur / Purchaser Rôle M-1851 M-203552 CASOLA, FRANCESCO Vendeur / Vendor et / and M-205519 CHIAZZESE, LIBORIO Acheteur / Purchaser Rôle M-1852 M-202556 FOURINER, ROGER Vendeur / Vendor et/and M-205486 DALPÊ, GERARD Acheteur / Purchaser Rôle M-1853 M -200997 D-2 GOLDBERG, ABRAM Vendeur / Vendor et / and M-205768 MEDIAT I.FELIPPIO Acheteur / Purchaser Rôle M-1854 M-200112 DACENAIS, GERARD Vendeur / Vendor et / and M-200205 D-2 COHEN, ISAAC Acheteur / Purchaser Rôle M-1855 M-203461 D-l MORRISSETTE, GAÉTAN Vendeur / Vendor et / and M-205729 FAVALLI, PIETRO Acheteur / Purchaser Rôle M-1856 M-204024 KANELLOPOULOS, CHRISTOS Vendeur / Vendor et / and M-205757 KARAVAS, CONSTANTIN Acheteur / Purchaser Rôle M-1857 M-204428 GRANGER, GUY Vendeur / Vendor et / and M-205761 HUOT, ROGER Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Milonakos, George demande à la Commission de transférer à: Kokkalakis, Nocolaos.7385.rue Stuart, app.2, Montréal, l'attestation numéro M-204848 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Casola, Francesco demande à la Commission de transférer à: Chiazzese, Liborio.7112, Vannes, St-Léo-nard, l'attestation numéro M-203552 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-5 Est de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Fouriner, Roger demande à la Commission de transférer à: Dalpé, Gérard, 85, De Caumont, Boucher-ville, l'attestation numéro M-202556 qu'il détient, pour desservir l'aggloméation A-2 Longueuil.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Goldberg, Abram demande à la Commission de tansférer à: Mediati, Felippio, 11627, Bossuet, Montréal-Nord, l'attestation numéro M-200997 D-2 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Dagenais, Gérard demande à la Commission de tansférer à: Cohen.Isaac, 990, Côte Vertu, app.205.St-Laurent, l'attestation numéro M-200112 qu'il détient pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Morrissette, Gaétan demande fi la Commission de transférer à: Favalli, Pietro, 9526.Millen, Montréal.l'atestation numéro M-203461 D-l qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Kanellopoulos, Christos demande à la Commission de transférer à: Karavas.Constantin, 8041.Birnam, Montréal, l'attestation numéro M-204024 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Granger, Guy demande à la Commission de transférer à: Huot, Roger, 644, Wilfrid Martin, St-Jé-rôme, l'attestation numéro M-204428 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-15 St-Jérôme.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Milonakos, George requests the Commission to transfer to: Kokkalakis, Nocolaos, 7385 Stuart Street, Apt.2, Montreal, ___ .his certificate number M-204848, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Casola, Francesco requests the Commission to transfer to: Chiazzese.Liborio.7112 Vannes, St.Léonard.his certificate number M-203552, to serve conglometation A-5, East of Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Fouriner, Roger requests the Commission to transfer to: Dalpé, Gérard, 85 De Caumont, Boucherville, his certificate number M-202556, to serve conglomeration A-2, Longueuil.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Goldberg, Abram requests the Commission to transfer to: Mediati, Felippio, 11627 Bossuet.Montreal-North, his certificate number M-200997 D-2, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Dagenais, Gérard requests the Commissin to tansfer to: Cohen, Isaac, 990 Côte Vertu.Apt.205, St.Laurent, his certificate number M-200112, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Morrisette, Gaétan requests the Commission to transfer to: Fa-valli, Pietro, 9526 Millen, Montreal, his certificate number M-203461 D-l, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Kanellopoulos, Christos requests the Commission to transfer to: Karavas, Constantin, 9041 Birnam, Montreal, his certificate number M-204024, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Granger, Guy requests the Commission to transfer to: Huot, Roger.644 Wilfrid Martin, St.Jérôme, his certificate number M-204428, to serve conglomeration A-15, St.Jérôme. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3653 Rôle M-1858 M-203127 D-2 PERREAULT, ANDRÉ Vendeur/Vendor et / and M-205550 GOYETTE, YVON Acheteur / Purchaser Rôle M-1859 M-203877 SMITH, DAVID WILLIAM Vendeur / Vendor et/and M-204475 D-2 SINGH, JASWANT Acheteur / Purchaser Rôle M-1860 M-205631 OHANESSIAN, MRS.MARY Vendeur / Vendor et / and M-205682 COHEN, ALBERT (Acheteur / Purchaser) Rôle M-1861 M-203941 TAPP, ANICET Vendeur / Vendor et / and M-205703 BRUNELLE, JEAN MARIE Acheteur / Purchaser Rôle M-1862 M-205103 EDUARDO RUCCOLO Vendeur / Vendor et / and M-205755 AQUINO PELLEGRINO Acheteur / Purchaser Rôle M-1863 M-200271 PILON, NAZAIRE Vendeur/Vendor et / and M-203727 D-2 NICOLA ANCELO C1R1NO Acheteur / Purchaser Rôle M-1864 M-203689 D-2 RODI, DOMINICO Vendeur / Vendor et / and M-205748 OUIMET, JEAN-LOUIS Acheteur / Purchaser Rôle M-1865 M-203060 TRÉPANIER, PATRICK Vendeur/Vendor et / and M-205566 CADORETTE, ROLAND Acheteur / Purchaser Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Perreault, André demande à la Commission de transférer à: Goyette, Yvon, 1926, Wolfe, St-Hubert.l'attestation numéro M-203127 D-2 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-24 St-Bruno.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Perreault, André requests the Commission to transfer to : Goyette Yvon, 1926 Wolfe, St-Hubert.his certificate number M-203127 D-2, to serve conglomeration A-24, St.Bruno.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Smith, David William demande à la Commission de transférer à: Singh, Jaswant, 2188, Lapierre, LaSalle, l'attestation numéro M-203877 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Ohanessian, Mrs.Mary demande à la Commission de transférer à: Cohen, Albert, 4855, Bourret, app.303.Montréal.l'attestation numéro M-205631 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Smith, David William requests the Commission to transfer to: Singh, Jaswant, 2188 Lapierre, LaSalle, his certificate number M-203877, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Ohanessian, Mrs.Mary requests the Commission to transfer to: Cohen, Albert, 4855 Bourret, Apt.303, Montreal, his certificate number M-205631, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Tapp, Anicet demande à la Commission de transférer à: Brunelle, Jean-Marie, 2005, Orléans, Montréal, l'attestation numéro M-203941 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-l 1 Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Tapp, Anicet requests the Commission to transfer to: Brunelle, Jean-Marie, 2005, Orléans, Montreal, his certificate number M-203941, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Eduardo Ruccolo demande à la Commission de transférer à: Aquino Pellegrino, 6305, Jean-Talon.Montréal, l'attestation numéro M-205103 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-5 Est de Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Eduardo Ruccolo requests the Commission to transfer to: Aquino Pellegrino, 6305 Jean-Talon, Montreal, his certificate number M-205103, to serve conglomeration A-5, East of Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Pilon, Nazaire demande à la Commission de transférer à: Nicola Angelo Cirino, 10579, André Jobin, Montréal, l'attestation numéro M-200271 qu'il détient pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Pilon, Nazaire requests the Commission to transfer to: Nicola Angelo Cirino, 10579 André Jobin.Montreal, his certificate number M-200271, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Rodi.Dominico demande à la Commission de transférer à: Ouimet, Jean-Louis, 9801 Boul.Lasalle.app.413,Lasalle, l'attestation numéro M-203689 D-2 qu il détient, pour desservir A-12 Ouest de Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Trépanier, Patrick demande à la Commission de transférer à: Cadorette, Roland, 65, Sherbrooke, Magog, l'attestation numéro M-203060 qu'il détient, pour desservir la région de Magog (05 3738 C.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Rodi, Dominico requests the Commission to transfer to: Ouimet, Jean-Louis, 9801 Lasalle Blvd.Apt.413, Lasalle, his certificate number M-203689 D-2, to serve conglomeration A-12, West of Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Trépanier, Patrick requests the Commission to transfer to: Cadorette, Roland, 65 Sherbrooke, Magog, his certificate number M-203060, to serve region of Magog (05 3738 C). 3654 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Rôle M-1866 M-205559 NASELLA, GINA Vendeur / Vendor et / and M-205583 BEDROSSIAN, VAZK1N Acheteur / Purchaser Rôle M-1867 M-202518 D-5 MARDINI, FOUAD Vendeur / Vendor et / and M-205750 STAMBELOS.STAMATIOS Acheteur / Purchaser Rôle M-1868 M-202608 COURNOYER, WILLIE Vendeur / Vendor et / and M-205591 RHEAULT, ANDRE Acheteur / Purchaser Rôle M-1869 M-204653 BELLEFEUILLE, JEANNE Vendeur / Vendor et / and M-200668 LATREILLE, EDOUARD Acheteur / Purchaser Rôle M-1870 M-203965 D-l l.AGACÉ.RENÉ Vendeur / Vendor et / and M-205606 1.ÉGARÉ.ARMAND Acheteur / Purchaser Rôle M-1871 M-204543 CARRIÈRE, CLAUDE Vendeur/Vendor et / and M-205689 ADRIAN, MAURICE Acheteur / Purchaser Rôle M-1872 M-203278 ABDELATIFF, IBRAHIM Vendeur/Vendor et / and M-202726 PEER, JUDDA Acheteur / Purchaser Rôle M-1873 M-200975 DELIDIMOS, NIKOLAOS Vendeur/Vendor et / and M-205749 TROUPAKIS, GEORGES Acheteur / Purchaser Cession de la propreté du système de transport (vente de taxi).Nasella.Gina demande A la Commission de transférer à: Bcdros8ian, Vazkin, 8325.L'Acadie, app.306, Montréal, l'attestation numéro M-205659 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Mardini.Fouad demande à la Commission de transférer à: Stambelos, Stamatios, 8792, Paquette, Ville I.iiSi.llc.l'attestation numéro M-202518 D-5 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Cournoyer, Willie demande à la Commission de transférer à: Rheault, André, 324 Millier, app.19, Sorel, l'attestation numéro M-202608 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-16 Sorel.Cession de la propriété du système de transport Bellefeuille, Jeanne demande à la Commission de transférer à : Latreille.Edouard, 4184, St-André, Montréal.l'attestation numéro M-204653 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lagacé.René demande à la Commission de transférer A: Légaré, Armand, 2735, Ontario Est.Montréal.l'attestation numéro M-203965 D-l qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Carrière, Claude demande A la Commission de transférer A: Adrian, Maurice, 4869, St-Denis, Montréal, l'attestation numéro M-204543 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du svstème de transport (vente de taxi) Abdelatiff.Ibrahim demande A la Commission de transférer A: Peer, Judda, 6398, Trans-Island, Montréal.1 attestation numéro M-203278 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Delidimos, Niko-laoa demande A la Commission de transférer A: Troupakis, Georges.5166, Esplanade, Montréal.l'attestation numéro M-200976 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Nasella.Gina requests the Commission to transfer to: Bedrossian, Vazkin.8325 L'Acadie, Apt.306.Montreal, her certificate number M-205569, to nerve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Mardini, Fouad requests the Commission to transfer to: Stambelos, Stamotios, 8792 Paquette, Ville LaSalle, hia certificate number M-202518 D-6, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi), Cournoyer, Willie requests the Commission to transfer to: Rheault.André, 324 Millier, Apt.19, Sorel.his certificate number M-202608, to serve conglomeration A-16.Sorel.Transfer of the ownership of transportation service Bellefeuille, Jeanne requests the Commission to transfer to : Latreille, Edouard, 4184 St-André, Montreal, her certificate number M-204653, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Lagacé, René requests the Commission to transfer to: Légaré, Armand, 2736 Ontario Est, Montreal, his certificate number M-203965 D-l, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Carrière, Claude requests the Commission to transfer to: Adrian, Maurice, 4869, St-Denis, Montreal, his certificate number M-204543, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Abdelatiff, Ibrahim requests the Commission to transfer to: Peer, Judda.6398 Trans-Island.Montreal, his certificate number M-203278.to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Delidimos, Nikolaos requests the Commission to transfer to: Troupakis, Georges, 6156 Esplanade, Montreal, his certificate number M-200976 to serve conglomeration A-ll, Montreal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3655 Rôle M-1874 M-202916 HENRI, OSCAR Vendeur/Vendor et / and M-201299 D-5 DEMERS, LÉO Acheteur / Purchaser Rôle M-1875 M-205516 MME JULIETTE MARCOTTE GOUPIL ès-qualité légatrice universelle in her capacity as universal le- Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Henri, Oscar demande à la Commission de transférer à: Demers, Léo, 1462, Jacques Lemaistre, Montréal.l'attestation numéro M-202916 qu'il détient, pour desservir l'agglomération À-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (décès) Mme Juliette Marcotte Goupil ès-qualité légatrice universelle pour Noël Goupil demande à la Commission de transférer à: Mme Juliette Marcotte Goupil, 125, Farwell, app.1, Sherbrooke, l'attestation numéro M-202057 que détenait le défunt, pour desservir l'agglomération A-43 Sherbrooke.125, Garwell, app.1, pour Noël Goupil Sherbrooke M-202057 Rôle M-1876 M-202614 LAMONTAGNE, FERNAND Vendeur / Vendor et / and M-205766 CUMMINGS, JIMMY Acheteur / Purchaser Rôle M-1877 M-200997 D-3 GOLDBERG, ABRAM Vendeur / Vendor et / and M-205747 RAFAEL, HAROLD Acheteur / Purchaser Rôle M-1878 M-203655 D-4 C1ROUX, GILLES Vendeur/Vendor et / and M-205543 CAMPEAU, GAÉTAN Acheteur / Purchaser Rôle M-1879 M-204632 D-4 TREMBLAY, PHILIPPE Vendeur/Vendor et / and M-205455 TREMBLAY, GILLES Acheteur / Purchaser I \u2014 AvÏ9 de la Commission « proprio motu » : La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Lamontagne, Fernand demande à la Commission de transférer à: Cummings, Jimmy, 307B, Havre-des-Iles, Laval.l'attestation numéro M-202614 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-2 Longueuil.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Goldberg, Abram demande à la Commission de transférer à: Rafael, Harold, 4630, Dupuis app.1, Montréal.l'attestation numéro M-200997 D-3 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Giroux, Gilles demande à la Commission de transférer à: Campeau, Gaétan, 5796, Des Erables, Montréal, l'attestation numéro M-203655 D-4 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-ll Montréal.Cession de la propriété du système de transport (vente de taxi).Tremblay, Philippe demande à la Commission de transférer à: Tremblay, Gilles, 369, Dufferin, Valleyfield, l'attestation numéro M-204632 qu'il détient, pour desservir l'agglomération A-44 Valleyfield.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Henri, Oscar requests the Commission to transfer to: De-mera, Léo, 1462 Jacques Lemaistre, Montreal, his certificate number M-202916, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of ownership of transportation service (death).Mrs Juliette Marcotte Goupil, in her capacity as universal legatee of Noël Goupil, requests the Commission to transfer to: Mrs Juliette Marcotte Goupil, 125 Farwell, Apt.1, Sherbrooke, certificate number M-202057, held by the deceased, to serve conglomeration A-43, Sherbrooke.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Lamontagne, Fernand requests the Commission to transfer to: Cummings, Jimmy, 307B, Havre des Iles, Laval, his certificate number M-202614, to serve conglomeration A-2, Longueuil.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Goldberg, Abram requests the Commission to transfer to: Rafael, Harold, 4630 Dupuis, Apt.1, Montreal, his certificate number M-200997 D-3, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Giroux, Gilles requests the Commission to transfer to: Campeau, Gaétan, 5796 Des Erables, Montreal, hiB certificate number M-203655 D-4, to serve conglomeration A-ll, Montreal.Transfer of the ownership of transportation service (sale of taxi).Tremblay, Philippe requests the Commission to transfer to: Tremblay, Gilles, 369 Dufferin, Valleyfield, his certificate number M-204632, to serve conglomeration A-44, Valleyfield.57197-o I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission : The Commission gives notice of its intention to decide on the following procedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Rôle Q-1145 19459-V-P-l GÉRARD BARON, 6605, Avenue Guy, Charlesbourg, Québec, P.Q.Aux fins de rayer du permis actuel de ce détenteur, le « Service à contrat » pour le compte de Robert Dechênes, No 22984-V, lequel permis est maintenant au nom de Berdec Transport Inc.For the purpose of deleting from the holder's present permit, the \"Contract Service\" on behalf of Robert Dechênes, No.22984-V, said permit being now issued in the name of Berdec Transport Inc. 3656 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, A'o.SO Rôle Q-1146 443-V-P-l HARVEY TRANSPORT LIMITÉE, Route St-Bruno, CP.638, Alma, Cté Lac St-Jean, P.Q.Rôle M-1906 19463-V ROLLAND DULUDE, 50, rue Vanier, St-Jean, Comté de St-Jean.P.Q.Rôle M-1942 602-A - (P.2.) SERVICE DE LIMOUSINE MURRAY HILL LTÊE, MURRAY HILL LIMOUSINE SERVICE LTD., 1380, rue Barré, Montréal, P.Que.IV \u2014 Avis de désistement: Aux fins de rayer du permis actuel de la détentrice, le droit additionnel No 2 (location) qui est expiré depuis le 20 avril 1974.For the purpose of deleting from the holder's present permit, additional right No.2 (leasing), which expired on April 20, 1974.Aux fins de réécrire la décision rendue le 1er novembre 1973.portant le numéro QCR-318.respecter le proprio motu du 31 janvier 1974.numéro M-1168, pour que le permis se lise dorénavant comme suit: Classe: Transport restreint - service local -Service : St-Jean à tous les endroits situés dans un rayon de 5 milles de ladite municipalité pour le transport de déchets industriels.Aux fins suivantes: « Corriger le paragraphe No 2 de la page 3 de la décision MPV 25, en date du 25 juillet 1973 pour qu'il se lise comme suit: « Autorise Service de Limousine Murray Hill Ltée \u2014 Murray Hill Limousine Service Ltd.», à donner à l'avenir son service par les parcours additionnels suivants sur son service Montréal à l'Aéroport International de Dorval, et retour, et ce dans le but de ne pas enlever à la requérante des parcours déjà autorisés en vertu de décisions antérieures.» La Commission donne avis du désistement des requêtes par les requérants dans les affaires suivantes: QDW-50 a) M.PAUL STE-MARIE DOSSIER: Q-201800 ROLE: 1150 Désistement de la requête de permis par véhicule-taxi relative à la municipalité de Loretteville.QDW-51 M.GREGOIRE PERREAULT DOSSIER: Q-200378-D-1 ROLE: 1148 Désistement de la requête de permis par véhicule-taxi relative à la municipalité de Vallée-Jonction.QDW-52 a) M.GREGOIRE PERREAULT DOSSIER: Q-200378-D-2 ROLE: 1149 Désistement de la requête de permis de transport par véhicule-taxi relative à la municipalité de Vallée-Jonction.QDW-53 M.JOSEPH ELIE TREMBLAY DOSSIER: Q-201544 ROLE: 1147 Désistement de la requête de permis de transport par véhicule-taxi relative à la municipalité de St-Aimé-des-Lacs.For the purpose of rewording the decision bearing number QCR-318, rendered on November 1, 1973, in conformity with the proprio motu notice numbered M-1158, dated January 31, 1974, so that the permit may read henceforth as follows: Class: Restricted trucking - local service -Service: St.Jean to all points located within a radius of 5 miles from said municipality for the transportation of industrial waste.For the following purposes: \"To correct paragraph 2 on page 3 of decision MPV-25, dated July 25, 1973, to read as follows: \"Authorizing Service de Limousine Murray Hill Ltée \u2014 Murray Hill Limousine Service Ltd., to provide its service henceforth via the following additional routes for its service from Montreal to Dorval International Airport, and return, the foregoing in order not to remove any routes which the applicant has been authorized to serve by previous decisions/' 57197-0 IV \u2014 Notice of withdrawal: The Commission gives notice of withdrawal of applications by the applicants in the following proceedings: QDW-50 (a) M.PAUL STE-MARIE FILE: Q-201800 ROLL: 1150 Withdrawal of application for a permit for trans portation by taxicab in the Municipality of Loretteville.QDW-51 M.GREGOIRE PERREAULT FILE: Q-200378-D-1 ROLL: 1148 Withdrawal of application for a permit for transportation by taxicab in the Municipality of Vallée-Jonction.QDW-52 (a) M.GREGOLRE PERREAULT FILE: Q-200378-D-2 ROLL: 1149 Withdrawal of application for a permit for transportation by taxicab in the Municipality of Vallée-Jonction.QDW-53 M.JOSEPH ELIE TREMBLAY FILE: Q-201544 ROLL: 1147 Withdrawal of application for a permit for transportation by taxicab in the Municipality of St.Aimé-des-Lacs.57197-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" 20 3657 V \u2014 Avis des décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément ii l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.DÉCISIONS DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » ,' DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QPV-279 TF\t29-04-74\t189-AP-l TF AUTOBUS LAVAL LTEE\t\t1665\t02-03-74\tQ-785\t Décision La Commission corrige sa décision QPV-213 TF du 24 janvier 1974.QPV-280 29-04-74 Q-2779-A-P-1 LEON CLOUTIER Décision La Commission corrige le paragraphe 2 de sa décision QPV-247 émise le 28 février 1974.QCS-296 29-04-74 Q-22984-V-P-1 BERBEC TRANSPORT INC.Décision La Commission: 1.Approuve le changement d'adresse de l'intimée devant se lire: Chemin Belair, St-Jean-Chrysostome, Comté de Lévis.2.Corrige la clause a du permis BERBEC TRANSPORT INC.QCR-530 29-04-74 Q-3653-V-P-1 THETFORD TRANSPORT LIMITEE Décisions La Commission prend et donne acte que les actionnaires et directeurs de THETFORD TRANSPORT LIMITEE sont les suivants: Marcel Pichette, président, 198 actions ordinaires.Guy Paquet, vice-président, 1 action ordinaire.Mme Gisèle Morin-Pichette, secrétaire, 1 action ordinaire.Decision The Commission corrects its decision QPV-213 TF dated January 24, 1974.2803 13-04-74 Q-964 Decision The Commission corrects paragraph 2 of its decision QPV-247, rendered on February 28, 1974.2803 13-04-74 Q-963 Decision The Commission : 1.Approves the change of address of the respondent, which should read: Chemin Belair, St.Jean-Chrysostome, County of Levis.2.Corrects clause a of permit BERBEC TRANSPORT INC.2803 13-04-74 Q-962 Decision The Commission acknowledges and certifies that the shareholders and directors of THETFORD TRANSPORT LIMITEE are the following: Marcel Pichette, President, 198 common shares.Guy Paquet, Vice-President, 1 common share.Mrs Gisèle Morin-Pichette, Secretary, 1 common share.AUDIENCES PUBLIQUES /PUBLIC HEARINGS QCR-532\t30-04-74\t23150-V-D-l LEON ARSENAULT\t\t4918\t25-09-73\tQ-70\tRejetée / Rejected QCR-533\t30-04-74\t3312-V-D-l CARON & FILS TRANSPORT INC.\t\t4800\t18-09-73\tQ-16\tRejetée / Rejected QCS-298\t30-04-74\t16944-V-D-l\t\t6218\t27-10-73\tQ-263\tAccordée en partie / Granted as amended \t\tLOGI8TEC CORPORA-\t\t\t\t\t \t\tTION\t\t\t\t\t QPV-281\t30-04-74\t3422-AP-l\t\t322\t19-01-74\tQ-556\t 3658 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tC page\t.O.Q.date\tCause Cose\tDécisions \t\t1606-AP-l AUTOBUS MESSIER (CHIBOUGAMAU) INC.COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUEBEC\t\t\t\tQ-556\t Décisions La Commission : 1.Décrète la révocation de la décision No QPV-114, rendue le 24 octobre 1973, dans la cause Q-12, comme elle décrète la révocation du permis délivré à AUTOBUS MESSIER (CHIBOUGAMAU) INC.en vertu de ladite décision.2.Décrète la confirmation de la décision No QPV-142, rendue le 8 novembre 1973 dans la cause RQ-180, comme elle confirme, en faveur de DONALD CAMPAGNA le permis dont la délivrance est autorisée par ladite décision.Decision The Commission: 1.Decrees the revocation of decision No.QPV-114, rendered on October 24, 1973, in case Q-12, and also decrees the revocation of the permit delivered to AUTOBUS MESSIER (CHIBOUGAMAU) INC.pursuant to said decision.2.Decrees the confirmation of decision No.QPV-142, rendered on November 8, 1973, in case RQ-180, as it confirms the delivery of a permit on behalf of DONALD CAMPAGNA, as authorized by said decision.SEANCES EN CHAMBRE/ SITTINGS IN CHAMBERS QCR-531\t29-04-74\t11367-VD-l\t\t4917\t23-08-73\tQ-66\tAccordée / Granted \t\tMURRAY BAY TRANSPORT LTD.Demande de transfert Application for transfer\t\t\t\t\t QCR-534\t01-05-74\t22621-D-l TF\t\t1672\t02-03-74\tQ-769\tAccordée / Granted TF\t\tJEAN-MARIE GOS8ELIN & FILS LTEE Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCR-535\t02-05-74\t3645-V-D-l TF\t\t1539\t23-02-74\tQ-681\tAccordée / Granted TF\t\tRAPIDE TRANSPORT INC.Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCR-636\t02-05-74\t10533-V-D-l TF\t\t1541\t23-02-74\tQ-691\tAccordée / Granted TF\t\tAUCLAIR TRANSPORT INC.Modification de tarifs Modification of tariffs\t\t\t\t\t QCS-293\t26-04-74\t15957-V-D-2 TF\t\t1540\t23-02-74\tQ-687\tAccordée / Granted TF\t\tGERARD NOLIN LIMITEE Modification de tarifs\t\t\t\t\t \t\tModification of tariffs 16239-V-D-2 TF\t\t\t\t\t QCS-294\t26-04-74\t\t\t1540\t23-02 74\tQ-688\tAccordée / Granted TF\t\tPERRON TRANSPORT LTEE Modification de tarifs\t\t\t\t\t QCS-296 TF\t\tModification of tariffs\t\t\t\t\t \t26-04-74\t14134-V-D-l TF PIERRE JORON SERVICE LIMITEE Modification de tarifs\t\t1540\t23-02-74\tQ-689\tAccordée / Granted QCS-297\t\tModification of tariffs\t\t\t\t\t \t29-04-74\t22621-V JEAN-MARIE GOS8ELIN Voiturier-roulier / Carrier Q-8063-V-D-1 LUCIEN GUERARD Voiturier-remorqueur Haulaway operator\t\t1445\t16-02-74\tQ-663\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3659 No Date Requérants Applicants Bulletin G.O.Q.page date Cause Case Décisions QCS-299 QPV-282 TF QPT-20 02-05-74 01-05-74 29-04-74 QPT-21 29-04-74 QPT-22 30-04-74 QPT-23 01-05-74 QPT-24 02-05-74 23597-V-D-l GREGOIRE CLOUTIER Voiturier-remorqueur Haulaway operator 1332-V ATLAS TRUCKING CO.LTD.Voiturier-roulier / Carrier 97-AD 6 TF AUTOBUS DRUMMONDVILLE LTEE Q-200473 GERALD SELESSE Requérant-vendeur A pplicant-vendor PAUL IRENEE FERLAND Requérant-acquéreur A pplicant-pur chaser Demande de transfert d'attestation Request for transfer of certificate Q-201787 JACQUES DEVEAULT Requérant-vendeur A pplicant-vendor GHISLAIN VEILLETTE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Demande de transfert d'attestation Request for transfer of certificate Q-200799 D-2 LEO ROY Requérant-vendeur A pplicant-vendor Q-200796 JEAN-MARC ROY Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser Demande de transfert d'attestation Request for transfer of certificate Q-201855 GASTON DERY Requérant-vendeur Applicant-vendor Q-200891-D-1 MARCEL DERY Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Demande de transfert d'attestation Request for transfer of certificate Q-200821 D-2 PAUL-EMILE NOLET Requérant-vendeur A pplicant-vendor RAYMOND BOUTIN Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Demande de transfert d'attestation Request for transfer of certificate 1120 2624 1446 02-02-74 06-04-74 16-02-74 Q-586 Q-0901 Q-670 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 1542 23-02-74 Q-699 Accordée / Granted 1546 23-02-74 Q-726 Accordée / Granted 1542 23-02-74 Q-696 Accordée / Granted 2131 16-03-74 Q-836 Accordée / Granted 3660 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO PERMIS SPECIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory So.QS-316 4221-V-S-l QS-317 7147-V-S-l Q8-318 2779-A-S-2 QS-319 3463-A-S-l QS-320 2450-V-S-l Nom du requérant Same of Applicant VICTOR TRANSPORT LTEE L.THIBODEAU TRANSPORT INC.LEON GAUTHIER TRANSPORT DES MONTS LTEE BAIE ST-PAUL TRANSPORT ENR.Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars of permit Transport général - longue distance - rayon -De Beauceville à tous les endroits dans un rayon de 250 milles, et retour.General trucking - long distance - radius -From Beauceville to all points located within a radius of 260 miles and return.Rejetée / Rejected.Autorisation à exploiter immédiatement le système de transport acquis de Albani Jean, 52, Avenue Royale, St-Joachim (Montmorency) en attendant le transfert de la clause b du permis No 7896-V se lisant comme suit: Transport général - longue distance - route restreinte - De Beaupré à Québec et retour.Authorization to operate immediately the transport service acquired by Albany Jean, 62 Royal Avenue, St.Joachim (Montmorency) pending the transfer of clause b of permit So.7896- V, which reads as follows: General trucking - long distance - restricted route - From Beaupré to Québec and return.Rejetée / Rejected.Classe de permis: Autobus Service: Transport de passagers, travaillants et autres de St-Odilon et St-Joseph Paroisse (Route St-Odilon) au parc industriel et Ville St-Joseph-de-Beauce, et retour pas de service local dans la ville de St-Joseph-de-Beauce.Class of permit- Bus Service: Transportation of passengers, workers and others, from St.Odilon and St.Joseph Parish (St.Odilon Road) to the industrial park and to the Town of St.Joseph-de-Beauce and return; no local service in the Town of St.Joseph-de-Beauce.Rejetée / Rejected.Classe de permis: Autobus Service: Transport d'étudiants (adultes) de cours du soir de Les Capucins, Cap-Chat et Ste-Anne-des-Monts à la polyvalente de Ste-Anne-des-Monts et retour.Class of permit: Bus Service: Transportation of students (adults) attending night courses, from Les Capucins, Cap-Chat and Ste.Anne-des-Monts to the Ste.Anne-des-Monts comprehensive school and return.Rejetée / Rejected.Transport restreint - longue distance - rayon -contrat - fardier - territoire - De Stoneham, entre et à l'intérieur des différentes concessions forestières de la Société forestière Domtar ltée situées dans la province de Québec, pour le transport, par fardier, de machinerie et équipements lourds pour le compte de ladite Société forestière Domtar ltée.Restricted trucking - long distance - radius - contract - float - territory - From Stoneham, between and within the various forest concessions of Domtar Woodlands Company Limited located in the Province of Quebec, for the transportation, by float, of heavy machinery and equipment on behalf of Domtar Woodlands Forest Company.Rejetée / Rejected. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3661 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-321 23345-V-S-2 164-DYL-S-l 163-DYL-S-l QS-322 TF 11437-V MTF-1 QS-323 TF 53-A MTF-2 QS-324 Q-23774-V-S-l 10694-V Q8-326 Q-23747-V-S-l Nom du requérant Name of Applicant JEAN-JACQUES SIMARD PRODUITS ALBA INC.GRENON FRERES LTEE Requérants^conjoints Jointe applicants L'ISLET EXPRESS INC.AUTOBUS A.DROLET LTEE VEILLETTE ET DRAPEAU INC.Voiturier-remorqueur Haulaway operator J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LIMITEE Voiturier-roulier / Carrier ROLAND VACHON Voiturier-remorqueur Haulaway operator Validité: de:.à: Validity Period Au 25-10-74 To 26-10-74 Au 31-12-74 ou décision finale de la Commission.7\"o Sl-12-74 or final decision of the Commission.Au 31-12-74 To Sl-12-74 Au 31-12-74 7Y> Sl-12-74 Détails du permis Particulars of permit 1.JEAN-JACQUES SIMARD demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - 1.De Dolbeau et Bagotville à Québec.Montréal et tous les points situés dans un rayon de 100 milles de Québec et Montréal pour le transport de produits de béton, et retour avec matières premières, le tout pour le compte de GRENON FRERES LTEE et PRODUITS ALBA INC.en utilisant une remorque appartenant à et louée desdites expéditrices.2.PRODUITS ALBA INC.demande l'autorisation de louer, à long terme, une remorque exclusivement à JEAN-JACQUES SIMARD.pour donner le service de transport ci-haut décrit.3.GRENON FRERES LTEE demande l'autorisation de louer, à long terme, une remorque exclusivement à JEAN-JACQUES SIMARD, pour donner le service de transport ci-haut décrit./.JEAN-JACQUES SIMARD requests the addition of the following service to his permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - 1.From Dolbeau and Bagotville to Québec, Montreal and all points located within a radius of 100 miles from Québec and Montreal for the transportation of cement, and return with raw materials, the whole on behalf of GRENON FRERES LTEE and PRODUITS ALBA INC., utilizing a trailer belonging to and leased from said shippers.2.PRODUITS ALBA INC., requests authorization to lease a trailer on a long-term basis, exclusively to JEAN-JACQUES SIMARD, in order for the latter to provide the aforesaid transport service.3.GRENON FRERES LTEE requests authorization to lease a trailer on a long-term basis, exclusively to JEAN-JACQUES SIMARD, in order for the latter to provide the aforesaid transport service.Modification de tarifs / Modification of tariffs.Accordée / Granted Modification de tarifs / Modification of tariffs.Accordée / Granted.VEILLETTE ET DRAPEAU INC.est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE (10694-V) selon la clause h dudit permis.VEILLETTE ET DRAPEAU INC.is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to J.P.BLANCHETTE LTEE according to clause h of permit 10694-V.ROLAND VACHON est autoriBé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.1C6, No.30 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permit 10694-V QS-326 Q-23775-V S-l 10694-V\tJ.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE Voiturier-roulier / Carrier CLAUDE SAVARD Voiturier-remorqueur Haulaway-operator J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE Voiturier-roulier / Carrier\tAu 31-12-74 To 31-12-74\t(10694-V) selon la clause h dudit permis.ROLAND VACHON is authorized to haul, with hit duly-registered tractors, the trailers belonging to J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE according to clause h of permit 10694-V.CLAUDE SAVARD est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE (10694-V) selon la clause h dudit permis.CLAUDE SAVARD is authorized to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to J.P.BLANCHETTE TRANSPORT LTEE according to clause h of permit 10694-V.67197-0 Places d'affaires dans la Province Places of Business in the Province J.LOWELL HOGG Prenez avis que l'adresse de « J.LOWELL HOGG » dans la province de Québec est 785 Chemin St-Joseph Bernières, Lévis, Québec.Les procureurs, 5726l-o Johnston, Heenan & Blaikie.J.LOWELL HOGG Notice is given that the address in the Province of Québec of \"J.LOWELL HOGG\" is 785 Chemin St-Joseph-Bernières, Lévis, Québec.Johnston, Heenan & Blaikib.57261-0 Attorneys.MC MILLAN & CO.LIMITED Avis est donné que la place d'affaires au Québec de « MC MILLAN & CO.LIMITED » sera au 255 Montée de Liesse, Montréal 377, province de Québec, téléphone 341-3411.Les procureurs de la requérante, 57284-0 Geoffrion & Prud'Homme.MC MILLAN & CO.LIMITED Notice is given that the place of business in the Province of Québec of MC MILLAN & CO.LIMITED\", will be located at 255 Montée-de-Liesse, Montreal 377, Province of Québec, Telephone 341-3411.Geoffrion & Prud'Homme, 57284 Attorneys for the petitioner.Associations coopératives Cooperative Associations LA COOPERATIVE FUNERAIRE DU PLATEAU (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement spécial adopté le 18 mars 1974 de « LA COOPERATIVE DE FRAIS FUNERAIRES DU PLATEAU», dont le siège social est situé à Québec, dans le district électoral de Louis-Hébert, changeant son nom en celui de « LA COOPERATIVE FUNERAIRE DU PLATEAU ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57282-u Albert Jessop.LA COOPERATIVE FUNERAIRE DU PLATEAU (Cooperative Associations Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the special bylaw, adopted on March 18, 1974, by \"LA COOPERATIVE DE FRAIS FUNERAIRES DU PLATEAU\", whose head office is located in Québec, in the Electoral District of Louis-Hébert, changing its name to \"LA COOPERATIVE FUNERAIRE DU PLATEAU\".Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57282 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' 20 LES LABORATOIRES SAGUENAY LIMITEE Prenez avis que la compagnie « LES LABORATOIRES SAGUENAY LIMITEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coop-pératives du Québec, l'abandon de sa charte.Chicoutimi, ce 6e jour de mai 1974.Le notaire, 57217-0 Me Jean Lapointe.LES LABORATOIRES SAGUENAY LIMITEE Notice is hereby given that \"LES LABORATOIRES SAGUENAY LIMITEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the companies act.Chicoutimi, this May 6, 1974.Me Jean Lapointe, 57217-o Notary.COORDINATION ET INTEGRATION DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT LTEE (C.I.T.E.) Prenez avis que la compagnie « COORDINATION ET INTEGRATION DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT LTEE (C.I.T.E.) » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, Michel Maurice Dagenais.1, Place Laval, Ville de Laval, Que.57218-o COORDINATION ET INTEGRATION DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT LTEE (C.I.T.E.) Notice is given that \"COORDINATION ET INTEGRATION DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT LTEE (C.I.T.E.)\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Michel Maurice Dagenais, Attorney for the Company.1, Place Laval, Ville de Laval, Que.57218 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LASALLE LASALLE PUBLIC LIBRARY Prenez avis par les présentes que la compagnie « BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LASALLE \u2014 LASALLE PUBLIC LIBRARY » compagnie dûment incorporée par lettres patentes de la province de Québec et ayant son siège social en la Cité de LaSalle, district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte, selon les dispositions de la Loi des compagnies.Signé, ce 25 avril 1974.Les procureurs de la compagnie.Chabot, Downs & Laurier, avocats.356 - 90e Avenue, Cité de LaSalle, Que.57219-o BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LASALLE LASALLE PUBLIC LIBRARY Notice is hereby given that \"BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LASALLE \u2014 LASALLE PUBLIC LIBRARY\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of LaSalle, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated this 25th day of April, 1974.Chabot, Downs & Laurier, lawyers.Attorneys for the company.356 - 90e Avenue, City of LaSalle, Que.57219-0 MAYOL REALTY CORP.Avis est par les présentes donné que « MAYOL REALTY CORP.» une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la Ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 7 mars 1974.Le procureur, Milton L.Klein, c.r.1010 St.Catherine St.West, Montreal, Que.H3B 1G7 57234-0 MAYOL REALTY CORP.Notice is hereby given that \"MAYOL REALTY CORP.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter in conformity with the provisions of the Companies Act.Dated in Montreal, on March 7, 1974.Milton l.Klein, q.c.Attorney for the company.1010 St.Catherine St.West, Montreal, Que.H3B 1G7 57234 Charte \u2014 Charter \u2014 demandes d'abandon de Application for Surrender of 3664 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 KASNER'S LINGERIE SHOPPE INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « KASNER'S LINGERIE SHOPPE INC.», corps politique incorporée suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce lie jour de mars, 1974.Le procureur de la compagnie, 57220-o Mtre.Emmanuel Cooke, c.r.KASNER'S LINGERIE SHOPPE INC.Notice is hereby given that \"KASNER'S LINGERIE SHOPPE INC.\", a corporation incorporated under the Companies act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 11th day of March, 1974.Mtre.Emmanuel Cooke, q.c.57220-o Attorney for the company.MONTREAL DYEING, CLEANING COMPANY LIMITED Prenez avis que la compagnie « MONTREAL DYEING, CLEANING COMPANY LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie.Mes Tanset, La very.Johnston, O'Donnell, Clark, Carrière.360, rue St-Jacques, Montréal, H2Y 1R8.57221-o MONTREAL DYEING, CLEANING COMPANY LIMITED Notice is herebv given that \"MONTREAL DYEING CLEANING COMPANY LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Mes Tanset, Lavery, Johnston, O'Donnell.Clark, Carrière, Solicitors of the Company.360, rue St.Jacques, Montréal, H2Y 1R8.57221-o KALAU INVESTMENT CO.LTD.Avis est donné par les présentes que « KALAU INVESTMENT CO.LTD », une corporation ayant son siège social dans la ville de Montréal, fera une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu de la Loi des compagnies.Montréal, le 1er jour d'avril, 1974.La secrétaire.57223-0 Martha Kalau.KALAU INVESTMENT CO.LTD.Notice is hereby given that \"KALAU INVESTMENT CO.LTD.\".a corporation having its head office in the City of Montreal will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Québec Companies Act.Montreal, this 1st day of April, 1974.Martha Kalau, 57223-0 Secretary.MAURICE THERRIEN INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie «MAURICE THERRIEN INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 23e jour d'avril 1974.Raymond Boyeh, avocat.1980 Sherbrooke ouest, Montréal.57225-o LOUIS J.BLACKBURN INC.Prenez avis que la compagnie « LOUIS J.BLACKBURN INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Maxime Langlois.580 est, Grande-Allée - 260, Québec 4, G1R2K2.57227-o MAURICE THERRIEN INC.Notice is hereby given that \"MAURICE THERRIEN INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, this 23rd day of April, 1974.Raymond Boyer, Advocate.1980 Sherbrooke West, Montreal.57225-o LOUIS J.BLACKBURN INC.Notice is given that \"LOUIS J.BLACKBURN INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Me.Maxime Langlois, Attorney for the company.580 est, Grande-Allée - 260, Québec 4, G1R2K2.57227 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3665 TONGALL HOLDING COMPANY LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « TONGALL HOLDING COMPANY LTD.» corps politique incorporé suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la Ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 7e jour de février, 1974.Le président, 57222-0 M.Herschel Segal.TONGALL HOLDING COMPANY LTD.Notice is hereby given that \"TONGALL HOLDING COMPANY LTD.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 7th day of February 1974.Mr.Herschel Segal, 57222-0 President.GLENMACK INC.Avis est par les présentes donné que « GLENMACK INC.», une corporation incorporée sous la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 22e jour d'avril 1974.La secrétaire, 57224-0 Shirley Mack.GLENMACK INC.Notice is hereby given that \"GLENMACK INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 22nd day of April 1974.Shirley Mack, 57224-0 Secretary.BAUFRY INVESTMENTS INC.LES INVESTISSEMENTS BAUFRY INC.Avis est donné par les présentes que la compagnie « BAUFRY INVESTMENTS INC.\u2014 LES INVESTISSEMENTS BAUFRY INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principle place d'affaires en les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 19e jour d'avril 1974.Les procureurs des requérants, Chait, Salomon, Gelber, Reis, 1, Place Ville Marie, Bronstein & Litvack.Montréal, H3B 3P3.57226 BAUFRY INVESTMENTS INC.LES INVESTISSEMENTS BAUFRY INC.Notice is hereby given that \"BAUFRY INVESTMENTS INC.\u2014LES INVESTISSEMENTS BAUFRY INC.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, on this 19th day of April, 1974.Chait, Salomon, Gelber.Reis, Bronstein & Litvack, 1, Place Ville Marie, Attorneys for applicants.Montreal, H3B 3P3.57226-o JUNEAU-GUENETTE INC.Prenez avis que « JUNEAU-GUENETTE INC.», corps politique dûment incorporé en vertu de la Loi des compagnies du Québec et ayant son siège social et sa principale place d'affaires dans la cité de Laval, district de Montréal, déposera une requête auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec aux fins d'obtenir l'abandon de sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 2e jour d'avril 1974.Les procureurs de la compagnie, Fiske, Emery & Lauzon.615 ouest, boul.Dorchester, Montreal.H3B 2P5 57232-o JUNEAU-GUENETTE INC.Notice is hereby given that \"JUNEAU-GUENETTE INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Laval, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 2nd day of April, 1974.Fiske, Emery & Lauzon, Attorneys for the company.615 ouest boul.Dorchester, Montreal.H3B 2P5 57232-0 3666 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO LES PUBLICATIONS ASSOCIEES INC.Avis est par les présentes donné que « LES PUBLICATIONS ASSOCIEES INC.», compagnie incorporée en vertu de la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de ladite loi.Donné à Montréal, ce 25e jour d'avril 1974.Les procureurs de la compagnie, 500, Place d'Armes, Geoffrion & Prud'homme.Montréal, Québec, Canada.57228-o CANOTEX LIMITED Prenez avis que la compagnie « CANOTEX LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2 mai, 1974.Les procureurs de la compagnie, Greenblatt, Ginsberg & Assocs.1440 Towers Street - 100 Montréal, Que.H3H 2C9 57229-0 HAMPSHIRE REALTIES LTD.Avis est par les présentes, donné que la compagnie « HAMPSHIRE REALTIES LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 30 avril 1974.Le directeur, 57230-o Jonathan J.Robinson.APHIA LIMITED Avis est par les présentes donné que « APHIA LIMITED » dont le bureau principal est situé dans la Ville de Montréal, province de Québec, fera une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, Québec, ce 30e jour d'avril 1974.La secrétaire, o7231-o Louise Wolvin.ENTREPRISES MARQUETTE INC.Avis est par les présentes donné que « ENTREPRISES MARQUETTE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 16 avril 1974.Les procureurs de la compagnie, Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent.630 ouest, boul.Dorchester - 2620 Montréal, Québec.H3B 1S6 57233-0 LES PUBLICATIONS ASSOCIEES INC.Notice is hereby given that \"LES PUBLICATIONS ASSOCIEES INC.\", a company incorporated under the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the said Act.Dated at Montreal, this 25th day of April, 1974.Geoffrion & Prud'homme, 500, Place d'Armes, Attorneys for the company.Montreal, Québec, Canada.57228-0 CANOTEX LIMITED Take notice that \"CANOTEX LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Province of Québec, for leave to surrender its charter.Montreal, May 2nd, 1974.Greenblatt, Ginsberg & Assocs, Attorneys for the company.1440 Towers Street - 100 Montreal, Que.H3H 2C9 57229-o HAMPSHIRE REALTIES LTD.Notice is hereby given that \"HAMPSHIRE REALTIES LTD.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30th day of April, 1974.Jonathan J.Robinson, 57230-o Director.APHIA LIMITED Notice is hereby given that \"APHIA LIMITED\" which has its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter in accordance with the provisions of the Companies Act.Montreal, Québec, this 30th day of April, 1974.Louise Wolvin, 57231-0 Secretary.ENTREPRISES MARQUETTE INC.Notice is hereby given that \"ENTREPRISES MARQUETTE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, April 16th, 1974.Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent, Attorneys for the company.630 ouest, boul.Dorchester - 2620 Montréal, Québec.H3B 1S6 57233-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3667 LA CAISSE POPULAIRE D'ASBESTOS (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 24 février 1974, par « LA CAISSE POPULAIRE D'ASBESTOS » modifiant son territoire qui était « Place d'affaires Asbestos » en celui de « Ville d'Asbestos, Trois-Lacs et Canton de Shipton ».Québec, le 8 mai 1974.Le tout-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57295-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE D'ASBESTOS (Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the by-law adopted on February 24, 1974, by \"LA CAISSE POPULAIRE D'ASBESTOS » changing its territory, which was \"Asbestos Business Centre\" to that of \"Town of Asbestos, Trois-Lacs and Township of Shipton\".Québec, May 8, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57295 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE HULL (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 26 février 1974, par « LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE HULL » modifiant son territoire qui était « la paroisse religieuse du Sacré-Coeur-de-Hull » en celui de « la cité de Hull ».Québec, le 8 mai 1974.L» sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57296-0 Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DU HULL (Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on February 26.1974, by \"LA CAISSE POPULAIRE DU SACRE-COEUR DE HULL\" changing its territory, which was \"the religious Parish of Sacré-Coeur-de-Hull\" to that of \"the City of Hull\".Québec, May 8, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57296 Companies and Cooperatives.CAISSE POPULAIRE VILLERAY ( Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 5 mars 1974 par « LA CAISSE POPULAIRE DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE DE MONTREAL », changeant son nom en celui de « CAISSE POPULAIRE DE VILLERAY».Québec, le 7 mai 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57297-0 Albert Jessop.CAISSE POPULAIRE VILLERAY (Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bvlaw adopted on March 5.1974, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE DE MONTREAL».changing its name to that of \"CAISSE POPULAIRE VILLERAY\".Québec, May 7, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57297 Companies and Cooperatives.CAISSE POPULAIRE MISTRAL (Loi des caisses d'épargne d de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 14 novembre 1973 par « LA CAISSE POPULAIRE DE STE-THERESE DE L'ENFANT-JESUS », changeant son nom en celui de « CAISSE POPULAIRE MISTRAL».Québec, le 2 mai 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57272-0 Albert Jessop.CAISSE POPULAIRE MISTRAL (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bvlaw passed on November 14, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE STE-THERESE DE L'ENFANT-JESUS\".changing its name to that of \"CAISSE POPULAIRE MISTRAL\".Québec, May 2, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57272 Companies and Cooperatives.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions 3668 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 CAISSE D'ECONOMIE BASE MONTREAL BASE MONTREAL CREDIT UNION (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a approuvé la requête des caisses d'épargne et de crédit « CAISSE D'ECONOMIE DE LA BASE DES FORCES CANADIENNES DE MONTREAL \u2014 CANADIAN FORCES BASE CREDIT UNION MONTREAL » et « CAISSE D'ECONOMIE LONGUEVETS \u2014 LONGUEVETS CREDIT UNION », datée du 31 janvier 1974 demandant la confirmation de l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux caisses.Le nom de la caisse résultant de cette fusion est: « CAISSE D'ECONOMIE BASE MONTREAL \u2014 BASE MONTREAL CREDIT UNION ».Le siège social de cette caisse est situé à St-Hubert dans le district électoral de Taillon.Le groupe dans lequel la caisse pourra recruter ses membres sera le personnel militaire et les employés civils de: \u2014 Canadian Forces Base Montreal \u2014 Canadian Forces Station Lac St-Denis \u2014 Canadian Forces Station Senneterre Cette caisse sera affiliée à la Ligue des Caisses d'Économie du Québec (1970).Québec, le 2 mai 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57271-0 Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE BASE MONTREAL BASE MONTREAL CREDIT UNION (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has granted the petition of the following savings and credit unions: \"CAISSE D'ECONOMIE DE LA BASE DES FORCES CANADIENNES DE MONTREAL \u2014 CANADIAN FORCES BASE CREDIT UNION MONTREAL\" and \"CAISSE D'ECONOMIE LONGUEVETS \u2014 LONGUEVETS CREDIT UNION\", dated January 31, 1974, requesting confirmation of the deed of agreement providing for the amalgamation of these two credit unions.The name of the credit union resulting from this amalgamation will be: \"CAISSE D'ECONOMIE BASE MONTREAL \u2014 BASE MONTREAL CREDIT UNION\".The head office of this credit union will be located in St.Hubert, in the Electoral District of Taillon.The group from which the credit union shall recruit its members will be the limitary personnel and civil employees of : \u2014 Canadian Forces Base Montreal \u2014 Canadian Forces Station Lac St-Denis \u2014 Canadian Forces Station Senneterre.This credit union will be affiliated to the Québec Credit Union League (1970).Québec, May 2, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57271 Companies and Cooperatives.Demandes à la Législature Applications to Legislature Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain Avis public est par les présentes donné que le Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, au cours de sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant la Loi du Bureau d'assainissement des eaux du Québec métropolitain pour les fins suivantes: 1.Donner au Directeur des services de protection de l'environnement, le pouvoir de déterminer les ouvrages à être incorporés aux réseaux du B.A.E.Q.M.et à la Commission municipale du Québec celui d'en déterminer les conditions d'acquisition; 2.Donner au B.A.E.Q.M.le pouvoir de teterminer et d'accorder s'il y a lieu des compensations pour les ouvrages exécutés avant le 1er janvier 1969 et celui de permettre le versement d'indemnités pour compenser pour les dépenses d'entretien de certains travaux et ce, à compter du 1er janvier 1969, le tout sujet à l'approbation de la Commission municipale du Québec; Greater Québec Water Purification Board Public notice is hereby given that the Greater Québec Water Purification Board shall apply to the National Assembly of the Province of Québec, during its current session, for the passing of a bill amending the Greater Québec Water Purification Board Act for the following purposes: 1.To provide to the Director of the protection of environment services with the authority to decide which works shall be incorporated to the network of the G.Q.W.P.B., and to provide the Québec Urban Community with the authority to decide upon the purchasing conditions; 2.To provide the G.Q.W.P.B.with the authority to decide upon and grant, as the case may be, compensations for'works carried out before January 1, 1969 and with the authority to pay indemnities to compensate for the maintenance charges, the foregoing to take effect from January 1, 1969, and subject to the approval of the Québec Municipal Community. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3669 3.Donner au B.A.E.Q.M.le pouvoir d'acquérir et d'être déclaré propriétaire de certains travaux municipaux malgré l'insuffisance des titres; 4.Accorder au B.A.E.Q.M.le pouvoir de contracter avec des corporations municipales aux fins d'assurer l'entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d'épuration des eaux qui pourraient se trouver sur leur territoire; 5.Accorder au Lieutenant-Gouverneur en Conseil le soin de déterminer la date à laquelle le B.A.E.Q.M.sera intégré à la Communauté urbaine de Québec; 6.Et pour toutes autres fins.Québec, le 7 mai 1974.Le procureur du Bureau d'assainissement, des eaux du Québec métropolitain, 57189-19-4-0 Ross Goodwin.Ville de Boucherville Avis public est par les présentes donné que la Ville de Boucherville s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte et la Loi constituant la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal, sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour autoriser le conseil à adopter des règlements pour accorder une pension aux membres du conseil; 3.Pour remplacer pour la Ville de Boucherville l'article 122 de la Loi des cités et villes concernant la mise en candidature ou la nomination des personnes au poste de maire ou de conseiller de la ville; 4.Pour amender les paragraphes 1 et le de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville de réglementer les lots qui doivent être utilisés pour fins de parcs publics et pour établir une nouvelle procédure d'approbation des règlements de zonage; 5.a) pour remplacer le 3e alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de $25 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 6) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 6.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés.7.Pour remplacer le paragraphe 2 de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances sur les terrains et l'enlèvement de telles nuisancts aux frais des propriétaires; 8.Pour remplacer l'article 593 de la Loi des cités et villes pour établir une nouvelle procédure dans le cas de l'adoption de règlements d'emprunts; 3.To grant to the G.Q.W.P.B.the authority to purchase or to be considered as the owner of various municipal works, notwithstanding the defectiveness of titles; 4.To grant to the G.Q.W.P.B.the authority to establish contracts with the municipal corporations in order to provide for the maintenance of the main sewers, pumping stations and water purification plants which may be found on their respective territories; 5.To grant the Lieutenant-Governor in Council the discretion to fix the date on which the G.Q.W.P.B.shall be integrated to the Québec Urban Community, 6.And for all other purposes.Québec, May 7, 1974.Ross Goodwin, Attorney for the Greater, 57189-19-4 Quebec Water Purification Board.Town of Boucherville Public notice is hereby given that the Town of Boucherville will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter and the Act incorporating the Montreal South Shore Transit Commission, for the following purposes; 1.To add paragraph 2a to article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission certain immoveables acquired with a restriction; 2.To authorize the Council to enact by-laws to grant a pension to the members of the Council; 3.To replace for the Town of Boucherville article 122 of the Cities and Towns Act regarding the nomination of persons for or appointment of persons to the office mayor or alderman of the Town; 4.To amend paragraphs 1 and lc of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to regulate the use of lands as public parks and to establish a new procedure for the approval of zoning by-laws; 5.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of $25 the fine provided for infractions to the traffic by-law; (6) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 6.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to enact a bylaw indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 7.To replace paragraph 2 of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; 8.To replace article 593 of the Cities and Towns Act to prescribe a new procedure in the case of the adoption of borrowing by-law; 3670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, Mi, Vol.106, No.20 9.Pour autoriser la ville à adopter des règlements sur réception de requêtes de propriétaires pour la construction de travaux publics; 10.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 11.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 12.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la ville; 13.Pour autoriser le conseil à adopter par règlement un plan quinquennal de dépenses en immobilisation; 14.Pour amender pour la ville l'article 21 de la Loi sur l'évaluation foncière concernant la taxation des terrains de fermes ou boisés; 15.Pour amender pour la ville l'article 25 de la Loi sur l'évaluation foncière afin de permettre l'envoi d'une copie du compte de taxes foncières générales municipales aux créanciers hypothécaires; 16.Pour amender pour la ville l'article 3 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal pour en exclure la Ville de Boucherville.Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 18 avril 1974.Ias procureurs de la Ville de Boucherville, VlAC, bélanger, HÉBERT.MaILLOUX, 57095-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.Ville de Pierrefonds Avis public est donné que la Ville de Pierrefonds s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente ou à une prochaine session, pour les fins suivantes; 1.Pour demander un amendement au projet de loi proposé amendant la Loi de la Communauté Urbaine de Montréal, pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la Loi de la Communauté Urbaine de Montréal, pour décréter que toutes les dépenses encourues par un service de la Communauté.excédant $100,000 au cours d'un même exercice financier, et occasionnées par un projet ou une manifestation organisé ou parrainé par une municipalité en dehors du cadre des services de la Communauté approuvés par le Conseil, seront à la charge de cette seule municipalité; 2.Pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la charte de la Ville de Pierrefonds en amendant l'article 429-8 de la Loi des cités et villes pour augmenter à dix pourcent (10%) la superficie de terrain ou la somme à être donnée à la ville pour fins de parc ou de terrain de jeux comme condition préalable à l'approbation d'un plan de subdivision; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Ville de Pierrefonds.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57100-17-4-o Beaurfgard, Paquet & Pinard.9.To authorize the Council to enact by-laws upon receipt of a petition of propriators for the construction of public works; 10.To authorize the Council to acquire immoveables, lo install public services and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and lo borrow for said purposes; 11.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 12.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the Town; 13.To authorize the Council to enact by by-law a \"Five-year plan for capital expenditures\"; 14.To amend for the Town article 21 of the Real Estate Assessment Act concerning the taxation of land used as farms or wood lots; 15.To amend for the Town article 25 of the Real Estate Assessment Act to authorize the insuance of a copy of the account for municipal general real estate taxes to the mortgage creditors; 16.To amend article 3 of the Act incorporating the Montreal South Shore Transit Commission to exclude Boucherville of the Montreal South Shore Transit Commission.And for all other purposes.Montreal.April 18th, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, o/095-17-4-o Attorneys for the Toicn of Boucherville.City of Pierrefonds Public notice is hereby given that the City of Pierrefonds will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purposes: 1.To request an amendment to the proposed Bill amending the Montreal Urban Community Act, or to obtain the adoption of an Act amending the Montreal Urban Community Act, to provide that all expenses incurred by a department of the Community, exceeding $100,000 in the course of a same fiscal year, and caused by a project or a manifestation organized or sponsored by a municipality outside of the framework of community services approved by the Council, shall be the responsibility of this single municipality; 2.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the City of Pierrefonds by amending article 429-8° of the Cities and Towns Act to increase to ten percent (10%) the area of land or the sum to be given to the City for park or playground purposes as a condition precedent to the approval of a subdivision plan; and for all other purposes.Montreal, April 23rd, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57100-17-4-o Attorneys for the City of Pierrefonds. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3671 Cité de Lachine Avis public est par les présentes donné que la Cité de Lachine s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, la disposition ou l'échange, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.a) Pour remplacer le troisième alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de vingt-cinq dollars ($25) la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; b) Pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale ; 3.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permetre à la Cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 4.Pour remplacer le paragraphe deuxième de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; 5.Pour autoriser le Conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin ; 6.Pour ajouter le paragraphe 4a à la Loi des fonds industriels afin qu'au cas d'expropriation des lots 548, 549 et 550, la cité en devienne propriétaire sur dépôt du montant de l'offre; 7.Pour permettre au Conseil, par règlement, d'octroyer des subventions en matière de rénovation urbaine; 8.Pour permettre au Conseil, par règlement, de constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de stabilisation des dépenses de déneigement » ; 9.Pour permettre au Conseil, par règlement, de modifier son règlement numéro 1003 pour la jetée extérieure du Canal Lachine; 10.Pour ratifier un échange de terrain entre la cité et Dominion Bridge Company Ltd.; 11.Pour abroger l'article 14 du chapitre 78 des lois de 1945 (9 Geo.VI); 12.Pour abroger l'article 15 du chapitre 78 des lois de 1945 (9 Geo.VI); 13.Pour abroger l'article 6 du chapitre 72 des lois de 1951-52 (15-16 Geo.VI) et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Cité de Lachine, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57097-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.City of Lachine Public notice is hereby given that the City of Lachine will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes : 1.To add paragraph 2a to Article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, disposal or exchange, at the conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction; 2.(a) To replace the third sub-paragraph of paragraph 17 of Article 426 of the Cities and Towns Act to allow Council to fix at a maximum of twenty-five dollars ($25) the penalty provided for infraction to the traffic by-law; (6) To add after paragraph 17 of Article 426 of the Cities and Towns Act, paragraph 17a which permits, in the case of contravention to the traffic and public security by-law, the issuance of a summary notice prior to any penal prosecution; 3.To add paragraph 20a to Article 429 of the Cities and Towns Act to allow the City to adopt a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks and private properties; 4.To replace the second paragraph of Article 472 of the Cities and Towns Act concerning nuisances; 5.To authorize the Council to acquire immoveables, to install therein public services and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for such purposes; 6.To add paragraph 4a to the industrial funds Act so that in the case of the expropriation of lots 548, 549 and 550, the City shall become owner upon deposit of the amount of the offer; 7.To authorize Council to give grants, by by-law, for urban renewal; 8.To authorize Council to constitute by by-law a snow removal expenses stabilization fund; 9.To authorize Council, by by-law, to amend its by-law number 1003 for the exterior jetty for the Lachine Canal; 10.To ratify an exchange of land between the City and Dominion Bridge Company Ltd.; 11.To repeal Article 14 of Chapter 78 of the laws of 1945 (9 Geo.VI); 12.To repeal Article 15 of Chapter 78 of the laws of 1945 (9 Geo.VI); 13.To repeal Article 6 of Chapter 72 of the laws of 1951-52 (15-16 Geo.VI) and for all other purposes.Montreal, April 23, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard Paquet & Pinard, 57097-17-4-o Attorneys for the City of Lachine. 3672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Ville de Kirkland Avis public est donné que la Ville de Kirkland s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe la à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, la disposition ou l'échange, aux conditions fixées par la Commission Municipale, d'immeuble acquis avec une restriction; 2.Pour obtenir l'adoption d'une Loi amendant la charte de la Ville de Kirkland en amendant l'article 429-8° de la Loi des cités et villes pour augmenter à dix pourcent (10%) la superficie de terrain ou la somme à être donnée à la ville pour fins de parc ou de terrain de jeux comme condition préalable à l'approbation d'un plan de subdivision; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Ville de Kirkland, Viau, Bélanger, Hébert, Maidloux, 57096-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.La Cité de Verdun Avis public est par les présentes donné que la Cité de Verdun s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour remplacer les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du paragraphe le de l'article 426 de la Loi des cités et villes afin d'établir une nouvelle procédure dans le cas d'amendements au règlement de zonage de la cité; 3.a) Pour remplacer le 3e alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de $25.00 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 6) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale.4.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 5.Pour amender l'article 449 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité de décréter par règlement que dans le cas d'immeubles de plus de 7 logements, la compensation pour l'usage de l'eau devra être payée par les propriétaires et pour décréter une diminution de la compensation pour l'usage de l'eau dans le cas d'immeubles inoccupés; 6.Pour remplacer le paragraphe 2 de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; Town of Kirkland Public notice is hereby given that the Town of Kirkland will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to Article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, disposal or exchange, at the conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction ; 2.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the Town of Kirkland by amending article 429-8° of the Cities and Towns Act to increase to ten percent (10%) the area of land or the sum to be given to the City for park or playground purposes as a condition precedent to the approval of a subdivision plan; and for all other purposes.Montreal, April 23, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57096-17-4-o Attorneys for the Town of Kirkland.The City of Verdun Public notice is hereby given that the City of Verdun will apply bo the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission cerrain immoveables acquired with a restriction; 2.To replace the 2nd, 3rd, 4th and 5th sub-parapraph of paragraph lc of article 426 of the Cities and Towns Act, to establish a new procedure in the case of amendments to the zoning by-law of the City; 3.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of $25.00 the fine provided for infractions to the traffic by-law; (6) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 4.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to enact a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 5.To amend article 449 of the Cities and Towns Act to authorize the City to decree by by-law that in the case of immoveables of more than seven apartments, the compensation for water shall be paid by the proprietors and to decree a reduction of said compensation in the cases of vacant premises; 6.To replace paragraph 2 of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3673 7- Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 8.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 9.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la cité; 10.Pour autoriser le conseil à adopter par règlement un plan quinquennal de dépenses en immobilisation; 11.Pour autoriser le conseil à constituer par règlement un fonds de stationnement; 12.Pour autoriser le conseil à décréter par règlement l'exécution de travaux permanents de rues, trottoirs, éclairages, etc.et à effectuer à cette fin des emprunts approuvés par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale de Québec; 13.Pour autoriser le conseil à adopter des règlements pour accorder une pension aux membres du conseil; 14.Pour autoriser le conseil à réunir certaines taxes en une seule taxe appelée « taxes de services » ; 15.Pour accorder à la cité le pouvoir d'effectuer elle-même son rôle de valeur locative; 16.Pour répartir tout ou partie du déficit de la cité accumulé au 31 décembre 1972 sur une période n'excédant pas 15 ans et contracter des emprunts à cette fin; 17.Pour abroger certains articles de la charte de la cité, soit: a) l'article 7 du chapitre 103 des lois de 1961 (9-10 Elizabeth 11); b) l'article 4 du chapitre 83 des lois de 1950 (14 Geo.VI); c) l'article 8 du chapitre 102 des lois de 1971.d) l'article 3 du chapitre 76 des lois de 1964 (12-13 Elizabeth n).et pour toutes autres fins.Montréal, ce 17 avril 1974.Les procureurs de la Cité de Verdun, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57101-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.Ville de La Prairie Avis public est par les présentes donné que la Ville de la Prairie s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe la à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission Municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour remplacer les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du paragraphe le de l'article 426 de la Loi des cités et villes afin d'établir une nouvelle procédure dans le cas d'amendements au règlement de zonage de la ville; 3.a) Pour remplacer le 3e alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la I*oi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de 825 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 7.To authorize the Council to acquire immoveables, to install public services therein and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; 8.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 9.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the City; 10.To authorize the Council to enact by by-law a \"Five-year plan for capital expenditures\"; 11.To authorize the Council to constitute by by-law a \"Parking Fund\"; 12.To authorize the Council to enact by by-law the execution of public works and to adopt borrowing by-laws for each purpose which shall be approved by the Minister of the Municipal Affairs and the Municipal Commission; 13.To authorize the Council to enact a by-law to grant a pension to the members of the Council; 14.To authorize the Council to join certain taxes into a \"Service Tax\"; 15.To authorize the City to prepare its own roll of rental values; 16.To apportion all or part of the deficit accumulated on the 31st of December 1972 over periods not to exceed 15 years and to adopt borrowing by-laws for such purpose.17.To repeal certain articles of the charter of the City, to wit: (a) Section 7 of Chapter 103 of the Statutes of 1961 (9-10 Elizabeth H); (6) Section 4 of Chapter 83 of the Statutes of 1950 (14 Geo.VI); (c) Section 8 of Chapter 102 of the Statutes of 1971.(d) Section 3 of Chapter 76 of the Statutes of 1964 (12-13 Elizabeth II).and for all other purposes.Montreal, April 17, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57101-17-4-o Attorneys for the City of Verdun.Town of La Prairie Public notice is hereby given that the Town of La Prairie will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes; 1.To add paragraph la to the article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction; 2.To replace the 2nd, 3rd, 4th and 5th sub-paragraphs of paragraph lc of article 426 of the Cities and Towns Act, to establish a new procedure in the case of amendments to the zoning by-law of the Town; 3.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of $25 the fine provided for infractions to the traffic by-law; 3674 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 b) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 4.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 5.Pour amender l'article 427-1 le de la Loi des cités et villes pour permettre au conseil de décréter par règlement que la compensation prévue à cet article est payable par les propriétaires; 6.Pour ajouter le paragraphe 8° à l'article 442 de la Loi des cités et villes pour décréter une diminution de la compensation pour l'usage de l'eau dans le cas d'immeubles inoccupés; 7.Pour remplacer le paragraphe 2° de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances sur des terrains et l'enlèvement de telles nuisances aux frais des propriétaires; 8.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission Municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 9.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement ; 10.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la ville; Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 18 avril 1974.Les procureurs de la Ville de La Prairie, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57098-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinahd.Cité de LaSalle Avis public est par les présentes donné que la Cité de LaSalle s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.a) Pour remplacer le troisième alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de vingt-cinq dollars ($25) la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 6) Pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 3.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; (6) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 4.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to authorize the council to enact a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 5.To amend article 427- 11c of the Cities and Towns Act to authorize the Council to enact by by-law that the compensation prescribed by said article is payable by the proprietors; 6.To add paragraph 8° to article 442 of the Cities and Towns Act to decree a reduction of the compensation in the cases of vacant premises; 7.To replace paragraph 2° of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; 8.To authorize the Council to acquire immoveables to install public services and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; 9.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 10.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the Town.And for all other purposes.Montreal, April 18th, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & » inard, 57098-17-4-o Attorneys for the Town of La Prairie.City of LaSalle Public notice is hereby given that the City of LaSalle will apply to the Québec National Assembly, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to section 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, at the conditions set by the Québec Municipal Commission, of immoveables acquired with a restriction; 2.(a) To replace the third sub-paragraph of paragraph 17 of Section 426 of the Cities and Towns Act to authorize Council to set at a maximum of twenty-five dollars ($25) the penalty provided for infraction to the traffic by-law; (6) To add after paragraph 17 of Section 426 of the Cities and Towns Act, paragraph 17a which authorizes, in the case of contravention to the traffic and public security by-law, the issuance of a summary notice prior to any penal prosecution; 3.To add paragraph 20a to Section 429 of the Cities and Towns Act to authorize the city to adopt a by-law indicating that the snow shall be blown or deposited on the sidewalks and private properties; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3675 4.Pour remplacer l'article 449 de la Loi des cités et villes afin de permettre au Conseil de décréter par règlement que la compensation pour l'usage de l'eau sera payée par les propriétaires dans les cas d'immeubles de plus de cinq (5) logements ou dans les cas d'immeubles commerciaux comprenant plusieurs commerces ainsi que d'accorder une diminution de cette compensation lorsque le logement aura été inoccupé pendant au moins trois (3) mois; 5.Pour amender le paragraphe 11c de l'article 427 de la Loi des cités et villes afin d'autoriser le Conseil à décréter par règlement que la compensation pour l'enlèvement des vidanges sera payée par les propriétaires dans les cas d'immeubles de plus de cinq (5) logements et dans les cas d'immeubles commerciaux comprenant plusieurs commerces ainsi que pour accorder une diminution de cette compensation pour toute période pendant laquelle une unité de logement aura été inoccupée pendant au moins trois (3) mois; 6.Pour amender l'article 122 de la Loi des cités et villes afin de préciser dans quels cas les locataires pourront être mis en candidature, élus ou nommés maire ou conseiller de la cité; 7.Pour remplacer le paragraphe deuxième de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; 8.Pour permettre au Conseil, par règlement, de constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de stabilisation des dépenses de déneigement » ; 9.Pour autoriser le Conseil à prohiber par règlement l'utilisation du nom, de l'écusson et des armoiries de la cité; 10.Pour amender l'article 517 de la Loi des cités et villes afin de permettre au conseil de déterminer le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires que la cité doit percevoir; 11.Pour autoriser le Conseil à accorder par règlement une pension aux membres du Conseil; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 22 avril 1974.Les procureurs de la Cité de LaSalle, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57099-17-4-o Beauregard, & Paquet, Pinard.Succession Pierre de Boucherville Avis est donné par les présentes que Jean E.Béique, domicilié à Westmount, et Y van Versailles, domicilié à Ville Mont-Royal, agissant en leur qualité de fiduciaires et exécuteurs testamentaires de la succession Pierre de Boucherville, s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec pour l'adoption d'une loi leur permettant d'effectuer le placement des fonds disponibles de cette succession conformément aux dispositions de l'actuel article 981-0 du Code civil, au lieu de conformément aux dispositions de ce même article en vigueur au moment de l'ouverture de la succession.Montréal, le 7 mai 1974.Les avocats des requérants, Kronstrom, Turmel, 57257-20-4-o Desjardins et Villeneuve.4.To replace Section 449 of the Cities and Towns Act to authorize the council to enact by by-law that the compensation for the use of water shall be paid by the owners in the case of immoveables of more than five (5) dwellings and in the case of commercial immoveables housing more than one business as well as to grant a reduction of said compensation when the dwelling has been inoccupied for at least three (3) months; 5.To amend paragraph 11c of section 427 of the Cities and Towns Act to authorize Council to enact by by-law that the compensation for garbage removal shall be paid by the owners in the case of immoveables of more than five (5) dwellings and in the case of commercial immoveables housing more than one business as well as to grant a reduction of said compensation for the period during which said dwelling shall have remained inoccupied for more than three (3) months; 6.To amend section 122 of the Cities and Towns Act to specify in what cases the tenants may be nominated, elected or appointed Mayor or councillor of the city; 7.To replace the second paragraph of Section 472 of the Cities and Tow-ns Act concerning nuisances; 8.To authorize the Council to create by by-law a snow removal expenses stabilization fund; 9.To authorize Council to prohibit by by-law the use of the City's name and coat of arms; 10.To amend section 517 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to set the rate of interest on the school tax arrears which the city must collect; 11.To authorize the Council to grant by by-law a pension to the members of Council ; and for all other purposes.Montreal, April 22, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57099-17-4-0 Attorneys for the City of LaSalle.Estate of Pierre de Boucherville Notice is hereby given that Jean E.Béique, domiciled in Westmount, and Yvan Versailles, domiciled in the Town of Mount Royal, acting as testamentary trustees and executors of the Pierre de Boucherville Estate, shall apply to the Québec National Assembly for the adoption of an Act enabling Ihem to invest the Estate's available funds according the requirements of article 981-0 of the Civil Code as presently formulated, instead of according to the requirements of this same article as it stood at the opening of the succession.Montreal, May 7th, 1974.Kromstrom, Turmel, Desjardins & Villeneuve, 57257-20-4-o Attorneys for petitioners. 3676 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 La Commission des écoles catholiques de Montréal Avis public est par les présentes donné que La Commission des écoles catholiques de Montréal s'adresse à l'Assemblée nationale du Québec pour demander l'adoption d'une loi modifiant la loi concernant la Commission des écoles catholiques de Montréal, en ce qui concerne le fonds de dotation et, entre autres, pour prévoir: o) une participation non obligatoire au fonds de dotation; 6) une participation limitée aux instituteurs y participant le jour de l'entrée en vigueur de la loi à être adoptée ou au plus tard le trente (30) juin 1974; c) la possibilité d'arrêt de participation à celui-ci et les remboursements à être effectués dans de tels cas: d) l'application des dispositions de la loi relatives au fonds de dotation, aux instituteurs et institutrices non laïques à compter du 1 er j uin 1969, et ce, sans autre effet rétroactif.Montréal, le 6 mai 1974.Les procureurs de la requérante, Bhi'net, Durand, Durocher & Denis.3737 est.rue Sherbrooke.Montréal.57264-20-4-o Ville de Ste-Agathe-des-Monts Avis public est donné que la Ville de Ste-Agathc-des-Monts s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa Charte sur la matière suivante: 1.Pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la charte de la ville de Ste-Agathe-des-Monts en amendant l'a-ticle 13 pou- diminuer le nombre des conseillers de huit (8) à six (6); et pour toutes autres fins.Montréal, ce premier jour de mai 1974.Les procureurs de la ville de Ste-Agathe-des-Monts, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard.57294-20-4-o Avis divers MATTAGAMI LAKE MINES LIMITED (No personal liability) MINES LAC MATTAGAMI LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et des compagnies minières, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 24e jour d'avril 1974, à « MATTAGAMI LAKE MINES LIMITED (No personal liability) \u2014 MINES LAC MATTAGAMI LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle) », modifiant son capital.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195 13594-53 The Montreal Catholic School Commission Notice is hereby given that the Montreal Catholic School Commission applies to the National Assembly of Québec lo request the adoption of a law to amend the law respecting the Montreal Catholic School Commission, concerning its endowment fund, in order to establish: a) a non compulsory participation; 6) a participation restricted to its teachers who are contributing to it at the date of the coming into force ot the proposed law or at the latest June, 30th 1974; c) the choice to end the participation to such fund, and the reimbursemenl of the appropriate sums; d) the full cxtention of the provisions of the endowment fund to the non lay teachers, as of June, 1st 1969, with no other retroactive effect.Montreal, May the 6th 1974.Brunet, Durand, Durocher & Denis, Attorneys for the Petitioner.3737 Sherbrooke St.East, Montreal.57264-20-4-o Town of Ste-Agathe-des-Monts Public notice is hereby given that the Town of Ste-Agathe-des-Monts will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purpose: 1.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the Town of Ste-Agathe-des-Monts by amending article 13 to reduce the number of councillors from eight (8) to six (6); and for all other purposes.Montreal, May 1st, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, Attorneys for the Town of Ste-Agathe-des-Monts.57294-20-4-o Miscellaneous Notices MATTAGAMI LAKE MINES LIMITED (No personal liability) MINES LAC MATTAGAMI LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle) Notice is given that, under Part I of the Companies Act and the Mining Companies Act, supplementary letters patent, dated the 24th day of April.1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to \"MATTAGAMI LAKE MINES LIMITED (No personal liability) \u2014 MINES LAC MATTAGAMI LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle)\", modifying its capital.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service 57195-o 13594-58 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO Paroisse de St-Timothée Avis public municipal en sue de la construction d'un barrage « Avis de la demande du dépôt des plan et devis » Avis est donné au public conformément à l'article 60 de la Loi du régime des eaux, que « La corporation municipale de la paroisse de St-Timothée », dans le comté de Laviolette, se propose de faire faire un barrage en béton de cent vingt-trois (123) pieds de longueur, pour l'emmagasinement en toute saison des eaux du lac Gagnon, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit et d'assurer ainsi l'uniformité d'alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques.Avis est de plus donné qu'une requête à cette fin, accompagnée des plan et devis indiquant l'emplacement de ces travaux et le terrain qui sera affecté par ces travaux, a été transmise au ministre des richesses naturelles, et qu'un duplicata de ces plan et devis a été déposé au bureau de la division d'enregistrement de Shawi-nigau, à Shawinigan.La demande d'autorisation contenue dans la requête sera prise en considération par le lieutenant-gouverneur en conseil le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Le secrétaire-trésorier.57277-0 Jean-Marie Trépanier.COLLEGE DE SAINT-CESAIRE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règle ment numéro 73-2 de « COLLEGE COMMERCIAL DE ST-CESAntE » constituée en vertu de l'Acte pour incorporer le Collège de Saint Césaire.39, Victoria, chapitre 82, changeant son nom en celui de « COLLEGE DE SAINT-CESAIRE », et ce, en vertu de l'article 2 de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57287-0 1715-1875 Parish of St.Timothée Municipal public notice regarding the construction of a dam \"Notice of application and deposit of plan and specifications\" Public notice is given that in conformity with section 60 of the Watercourses Act, that \"La corporation de la paroisse de St-Timothée\", in the County of Lacio-lette, intends to have constructed a concrete dam of a lenght of one hundred and twenty-three feet (123), for the storage in all seasons of the waters of Lake Gagnon, with the object of conserving them so as to regulate their flow, and thus to ensure a uniform supply to waterworks systems and to mills, and a constancy of hydraulic power.Notice is also given that a petition to that effect, accompanied by a plan and specifications showing the site and the nature of such work, and the land which will be affected by such work, has been forwarded to the Minister of Natural Resources, and that a duplicate of such plan and specifications has been deposited at the Registry Office of the registration division of Shawinigan, in Shawinigan.The application for authorization contained in the petition will be taken into consideration by the Lieutenant-Governor in Council on or after the tenth day following the date of the publication of this notice in the Québec Official Gazette.Jean-Marie Trépanier, 57277 Secretary-Treasurer.COLLEGE DE SAINT-CESAIRE Notice is given that the Minister of Financial Insti tutions.Companies and Cooperatives has approved bylaw number 73-2 of \"COLLEGE COMMERCIAL DE ST-CESAIRE\", incorporated under the Act to incorporate Collège de Saint-Ccsaire, 39 Victoria, Chapter 82, changing its name to that of \"COLLEGE DE SAINT-CESAIRE\", the foregoing, pursuant to section 2 of the Special Corporate Powers Act.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57287 1715-1875 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Leopold Mignault Prenez avis que monsieur Leopold Mignault domicilié au 162, rue St-Georges, St-Lazare, cté Bcllechasse, présentera une demande au Lieutenant-gouverneur en conseil pour que son nom de famille soit changé pour le nom de « Aubin ».Les procureurs du requérant, 57148-19-2-0 Turgeon & Brodeur, avocats.Change of name \u2014 Act Applications Leopold Mignault Notice is given that Mr.Leopold Mignault, domiciled at 162 St.Georges Street, St-Lazare, County of Belle-chasse will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his surname to that of \"Aubin\".Turgeon & Brodeur, lawyers, 57148-19-2 Attorneys for the Applicant. 3678 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.30 Normand Bacon Avis est par les présentes donné que Joseph Yves Normand Bacon, domicilié à 333 Broadway, Shawinigan, P.Q., s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil par l'entremise du Ministère de la Justice pour obtenir un décret changeant son nom pour s'appeler à l'avenir Joseph Yves Normand Lajoic.Mme Joseph Yves Normand Bacon, née Lise Descôteaux, épouse du requérant, ainsi que Marie Christine Annie Bacon et Joseph Stéphane François Bacon, enfants du requérant, domiciliés également à 333 Broadway, changeront de nom à la suite de la requête pour s'appeler Mme Joseph Yves Normand Lajoie, Marie Christine Annie Lajoie et Joseph Stéphane François Lajoie.Shawinigan, 28 mars 1974.Le procureur du requérant, 57147-19-2-0 Léon Lamothk.Marie Éva Bolduc Avis est par les présentes donné que Marie Éva Bol-duc, vendeuse, présentement domiciliée à Montréal, province de Québec, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Evelyne Bolduc.Montréal, le 25 avril, 1974.Les procureurs de la requérante, 57165-19-2-0 Morris & Kravitz.Normand Bacon Notice is hereby given that Joseph Yves Normand Bacon, residing and domiciled at 333 Broadway Shawinigan, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Joseph Yves Normand Bacon to Joseph Yves Normand Lajoie, Mrs.Joseph Yves Normand Bacon, born Lise Descôteaux, applicant's wife, Marie Christine Annie Bacon and Joseph Stéphane François Bacon, applicant's children, also residing and domiciled at 333 Broadway Shawinigan, will also have their names changed to Mrs.Joseph Yves Normand Lajoie, Marie Christine Annie Lajoie and Joseph Stéphane François Lajoie.Shawinigan, March 28 1974.Léon La.mothe, 57147-19-2-0 Attorney for the Applicant.Marie Éva Bolduc Notice is given that Marie Éva Bolduc, salesgirl, presently domiciled in Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Evelyne Bolduc.Montreal, April 25th, 1974.Morris & Kravitz, 57165-19-2-0 Attorneys for Applicant.Joseph-Pierre Aldège Cyr Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la Loi du changement de nom, M.Joseph-Pierre Aldège Cyr, domicilié au 341 boulevard Rochette, Beauport, district de Québec, présentera au lieutenant-gouverneur en conseil une requête pour changer son nom de Joseph-Pierre Aldège Cyr en celui de Joseph-Pierre Alain Cyr.Québec, le 28 mars 1974.Les procureurs du requérant, 57166-19-2-0 Gauvin, Bélanger & Cloutieh.Joseph-Pierre Aldège Cyr Notice is hereby given that pursuant to the Change of Name Act, Mr.Joseph-Pierre Aldège Cyr, domiciled at 341 Rochette Boulevard, Beauport, District of Québec, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name from Joseph-Pierre Aldège Cyr to Joseph-Pierre Alain Cyr.Québec, March 28th, 1974.Gauvin, Bélanger & Cloutier, 57166-19-2 Attorneys for Applicant.Henri Abboud Avis est donné par les présentes que Henri Abboud, étudiant, domicilié à Montréal et résident au 4820 Plamondon, présentera une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Henri Simon.57235-20-2-o Raymond Bourassa Nous donnons avis que Raymond Bourassa, domicilié au 341, rue Richard, Chomedey, Laval, district de Montréal, s'adressera au Lieutenant-Gouverneur en Conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de: Raymonde Bourassa.Laval, le 28 décembre 1973.Les procureurs du requérant, Si-Aubin, Charbonneau, 57237-20-2-o Laviolette.Henri Abboud Notice is hereby given that Henri Abboud, student, domiciled in Montreal and residing at 4820 Plamondon, will apply to the minister of Justice for an order changing his name to Henri Simon.57235-20-2-o Raymond Bourassa Notice is given that Raymond Bourassa, domiciled at 341 Richard Street, Chomedey, Laval, district of Montreal, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his name to that of Raymonde Bourassa.Laval, December 28, 1973.St-Aubin, Charbonneau, Laviolette, o723 t -20-2-o Attorneys for the A pplicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3679 Marie, Anne, Lauretta, Armande Badeau Avis est donné que Marie, Anne, Lauretta, Armande Badeau veuve de Léo Gravel, domiciliée au 1776 rue St-Philippe, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de Marie, Anne, Lauretta, Germaine Badeau.Trois-Rivières, ce 29 avril 1974.Les \"procureurs de la requérante, Langevin, Vigeant, 57164-19-2-0 Ayotte & Crête.Joseph Etienne Gérard Gaucher Avis est par les présentes donné que M.Joseph Etienne Gérard Gaucher, domicilié à St-André Est, comté d'Argenteuil, district de Terrebonne, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Etienne Gérard Gauthier.St-Jérôme, le 30 avril 1974.Les procureurs du requérant, 57167-19-2-0 Charette, Soumis & Lussifr.Donald Dow Good Avis est par les présentes donné que Donald Dow Good gentilhomme, résidant et domicilié au 1280 boul.Décarie, App.27, dans la Cité de St-Laurent, district de Montréal, fera application au ministère de la justice pour changer son nom à Donald Edmund Allen lequel changement de nom aura bénéfice à sa femme née Edith Evelyn Jean Covey et à tous leurs enfants qui naîtront.St-Laurent, ce 12e jour de février, 1974.Les procureurs du requérant, 57236-20-2-o Descoteaux, Rosen & Laverdure Serge Dozois Serge Dozois, présentement sans emploi, résidant et domicilié au 1912 Parthenais, dans les cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom de famille de Dozois à Lefebvre.Montréal, le 20 février, 1974.Les procureurs du requérant, St-Louis, 57238-20-2-o Labelle & Charbonneau.Joseph, Georges, Edgar Gélinas Avis est donné que Joseph, Georges, Edgar Gélinas, chômeur, domicilié au 341 rue Bureau à Trois-Rivières, dudit district, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtension d'un décret changeant son nom en celui de Joseph, Georges, Germain Gélinas.Trois-Rivières, ce 1er mai 1974.Les procureurs du requérant, Langevin, Vigeant, 57239-20-2-o Ayotte & Crête.Marie, Anne, Lauretta, Armande Badeau Notice is hereby given that Marie, Anne, Lauretta, Armande Badeau, widow of Léo Gravel, residing at 1776 St-Philippe Street, city and district of Trois-Rivières, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing her name to Marie, Anne, Lauretta, Germaine Badeau.Trois-Rivières, this 29th of April 1974.Langevin, Vigeant, Ayotte & Crête, 57164-19-2-0 Attorneys for Petitioner.Joseph Etienne Gérard Gaucher Notice is hereby given that Mr.Joseph Etienne Gerard Gaucher residing at St-André Est, county of Ar-genteuil, district of Terrebonne, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Joseph Etienne Gérard Gauthier.St-Jérôme, April 30th, 1974.Charette, Soumis & Lussier, 57167-19-2-0 Attorneys for the Petitioner.Donald Dow Good Notice is hereby given that Donald Dow Good, gentleman, domiciled and residing at 1280 Décarie Blvd., Apt.27, in the City of St.Laurent, District of Montreal, will apply to the Minister of Justice to change his name to : Donald Edmund Allen said change of name to benefit his wife, née Edith Evelyn Jean Covey and any and all of their children to be born.St.Laurent, this 12th day of February, 1974.Descoteaux, Rosen & Laverdure, 57236-20-2-o Attorneys for Petitioner.Serge Dozois Serge Dozois, presently unemployed, residing and domiciled at 1912 Parthenais, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Serge Lefebvre.Montreal, February 20, 1974.St-Louis, Labelle & Charbonneau, 57238-20-2-o Attorneys for Petitioner.Joseph, Georges, Edgar Gélinas Notice is hereby given that Joseph, Georges, Edgar Gélinas, unemployed, residing at 341 Bureau Street, in the city and district of Trois-Rivières, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his name to Joseph, Georges, Germain Gélinas.Trois-Rivières, this 1st day of May, 1974.Langevin, Vigeant, Ayotte & Crête, 57239-20-2-o Attorneys for Petitioner. 3680 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Ferdinand Lalonde Nous donnons avis que Ferdinand Lalonde, mécanicien, domicilié au 620, rue Évariste Leblanc, à Laval, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de: Fernand Lalonde.Laval, ce 7e jour de novembre 1973.Les procureurs du requérant, GoNTMF.rt, Barrière 57240-20-2-o & Charbonnbau, avocats.Ferdinand Lalonde Notice is given that Ferdinand Lalonde, mechanic, domiciled at 620 Évariste Leblanc Street, in Laval, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Fernand Lalonde.Laval, this 7th day of November, 1973.Gonthier, Barrière & Charbonneau, Advocates.57240-20-2 Attorneys for applicant.Joseph Lucien Edouard Richard Marcoux Avis est donné par les présentes, que Monsieur Joseph Lucien Edouard Richard Marcoux, domicilié et résidant au 39 rue Lamer, Vimont, Ville de Laval, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afir.d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Richard Lavoie.Montréal, ce 8 février 1974.Les procureurs du requérant.Mes Saint-Aubin, Charbonneau, 57241-20-2-o & Laviolette.Joseph Lucien Edouard Richard Marcoux Notice is hereby given that Mr.Joseph Lucien Edouard Richard Marcoux, domiciled and residing at 39 Lamer Street, Vimont, City of Laval, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Richard Lavoie.Montreal, February 8th, 1974.Mes Saint-Aubin, Charbonneau, & La violette, 57241-20-2-o Attorneys for applicant.Richard Mercier Avis est, par les présentes, donné que Richard Mercier, journalier, demeurant à 737 rue Cousineau, Cité de Laval, District de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Richard Paquin.Montréal, ce 3e jour d'avril 1974.Le procureur du requérant, 57242-20-2-o Gilles I.Beaupré.Richard Mercier Notice is hereby given that Richard Mercier, laborer, residing at 737 Cousineau St., City of Laval, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing his name to that of Richard Paquin.Montreal, this 3rd day of April 1974.Gilles I.Beaupré, 57242-20-2-o Attorney for petitioner.Oleh Michaelchuk Prenez avis que Oleh Michaelchuk, du 1585 avenue McGregor, app.31, dans les ville et district de Montreal, province de Québec, va s'adresser au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour changer son nom de Oleh Michaelchuk à Oleg Jonathan Michaels.Daté à Montréal, Que., ce 30e jour d'avril 1974.Le procureur du requérant, 57243-20-2-o Alexandre Bieoa, ch.Oleh Michaelchuk Take notice that Oleh Michaelchuk, of 1585 McGregor Avenue, Apt.31, in the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to change his name from Oleh Michaelchuk to Oleg Jonathan Michaels.Dated at Montreal, Que., this 30th day of April, 1974.Alexander Bieoa, q.c, 57243-20-2-o A ttorney for petitioner.Harvey Modlinsky Nous donnons par les présentes avis que Harvey Modlinsky, étudiant, domicilié et résidant au 5703 Wolseley, en la Cité de Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de: Harvey Modlin.Montréal, ce 15e jour de mars, 1974.Les avocats du requérant, 57244-20-2-o Descotfaux, Rosen & La verdure.Harvey Modlinsky Notice is hereby given that Harvey Modlinsky, student, domiciled and residing at 5703 Wolseley Street, in the City of Côte St.Luc, in the District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to: Harvey Modlin.Montreal, this 15th day of March, 1974.Descoteaux, Rosen & La verdure, 57244-20-2-o Attorneys for petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3681 John Aldershot Moore Avis est par les présentes donné que John Aldershot Moore de la cité de Dorval, Québec, résidant et domicilié à 1701 Parkfield, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom à John Moore Skanes, celui-ci lui bénéficiant, ainsi qu'à sa femme, Jean Blackshaw Bennett, demeurant à la même adresse, cette dernière ayant consenti à ce changement.Montréal, 8 avril 1974.57245-20-2-o John Aldershot Moore Notice is hereby given that John Aldershot Moore of the City of Dorval, Québec, therein domiciled and residing at 1701 Parkfield Avenue will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an Order changing his name to John Moore Skanes, said change of name to benefit himself, and his wife, Jean Blackshaw Bennett, of the same address, the latter having consented to the requested change of name.Montreal, 8 April, 1974.57245-20-2-o Emile Moreau Avis est par la présente donné que Emile Moreau, demeurant et domicilié au 1594 de la rue Quinn à Longueuil, district de Montréal, demande au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter officiellement le nom de Emile Laroche.Longueuil, le 29 avril 1974.Les procureurs du requérant.Pilon, Ferrari, Braconnier 57246-20-2-o & Larivière.Emile Moreau Notice is hereby given that Emile Moreau, residing at 1594, Quinn in Longueuil, district of Montreal will make application to the Lieutenant-Governor in council to have his name changed to Emile Laroche.' Longueuil, this April 29, 1974.Pilon, Ferrari, Braconnier & Larivière.57246-20-2-o Attorneys for petitioner.Valère Pauzé-Masse Avis est par les présentes donné que Valère Pauzé-Masse, domiciliée au 10,761, rue Gariépy app.6, en la ville de Montréal-Nord, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Dame Rita Pauzé-Masse.Montréal, le 9 avril 1974.Les procureurs de la requérante, 57248-20-2-o Cloutier, Tellier et cayer.Valère Pauzé-Mas9e Notice is hereby given that Valère Pauzé-Masse, residing at 10,761, Gariépy St.App.6 City of Montreal-North, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of a decree changing her name to Rita Pauzé-Masse.Montreal, April 9, 1974.Cloutier, Tellier & Cayer, 57248-20-2-o Attorneys for petitioner.Marie Alcida Françoise Georgette Potvin Avis est par les présentes donné que Marie, Alcida, Françoise, Georgette Potvin, professeur, domiciliée au 121 d'Orléans, à Ste-Julie de Verchères, district de Richelieu, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son prénom de Georgette en celui de Julie.St-Bruno de Montarville, ce 28e jour de mars 1974.Le procureur de la requérante, 57249-20-2-o Bernard Tremblay.Marie Alcida Françoise Georgette Potvin Notice is given that Marie, Alcida, Françoise, Georgette Potvin, teacher, domiciled at 121 d'Orléans in the town of Ste-Julie de Verchères, district of Richelieu, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing her name of Georgette to that of Julie.St-Bruno de Montarville, this 28 of March, 1974.Bernard Tremblay, 57249-20-2-o Attorney for applicant.Charles Yakubowski Nous donnons par les présentes avis que Charles Yakubowski, étudiant, domicilié et résidant au 1685 rue St-Louis, en la cité de St-Laurent, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de Charles Jacobs.Montréal, ce 18e jour de mars, 1974.Les procureurs du requérant.Descoteaux, 57298-20-2-o Rosen & Laverdure.Charles Yakubowski Notice is hereby given that Charles Yakubowski, student, domiciled and residing at 1685 St.Louis Street, in the city of St.Laurent, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Charles Jacobs.Montreal, this 18th day of March, 1974.Descoteaux, Rosen & Laverdure, 57298-20-2-o Attorneys for Petitioner. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Marline Morin Avis est donné que Marline Morin, étudiante, domiciliée et résidant au 114, 7e avenue à Ville St-Pierre, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Marline Kunetzky.Lachine, ce 22 mars 1974.Les procureurs de la requérante, 57247-20-2-o Barrière, Brott & Neuer.Marline Morin Notice is given that Marline Morin, student, residing and domiciled at 114-7th Avenue.Ville St-Pierre, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing her name to Marline Kunetzky.Lachine, March 22, 1974.Barrière, Brott & Neuer, 57247-20-2-o Attorneys for the applicant.Hermine Parent Ratté Prenez avis que Hermine Parent Ratté, épouse de Roger Ratté, domiciliée au Xo 1735, boul.Lévesque, à Duvernay, ville de Lava), a présenté une requête, conformément à la Loi du changement de nom (L.Q.1965, ch.77) pour changer son prénom en celui de Hermione Parent Ratté.Montréal, ce 29 mars 1974.Les procureurs de la requérante, 57250-20-2-o Renaud & Boucher.Hermine Parent Ratté Notice is given that Hermine Parent Ratté, wife of Roger Ratté, domiciled at 1735 Lévesque Boulevard, Duvernay, City of Laval, has applied persuant to the Change of Name Act (S.Q.1965, Chap.77) to change her surname to that of Hermione Parent Ratté.Montreal, March 29, 1974.Attorneys for Petitioner, 57250-20-2 Renaud & Boucher.Saul Salemovitch Avis est par les présentes donné que Saul Salemovitch, vendeur, demeurant au numéro 3250 Van Home, Appartement 9, Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Sol Solomon.Montréal, le 18 avril 1974.Le procureur du requérant, 57251-20-2-o June Gagnon.Saul Salemovitch Notice is hereby given that Saul Salemovitch, salesman, residing at 3250 Van Horne, Apartment 9, Montreal, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Sol Solomon.Montreal, April 18, 1974.June Gagnon, 57251-20-2-o Attorney for A pplicant.Michel Sincennes Prenez avis que monsieur Michel Sincennes, domicilié au 266 B, rue St-Laurent, Lévis, présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que son nom de famille soit changé pour le nom de Tremblay.Les procureurs du requérant.57252-20-2-o Turgeon & Brodeur, avocats.Michel Sincennes Notice is given that Mr.Michel Sincennes, domiciled at 266 B, St.Laurent Street, Lévis, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his family name to Tremblay.Turgeon & Brodeur, Lawyers, 57252-20-2 Attorneys for Petitioner.Chaya Reigal Solomonovitch Avis est donné que Chaya Reigal Solomonovitch, épouse en séparation de biens de Norman Shaffran, résidant à 5554 avenue Alpine, dans la cité de Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un ordre changeant son nom en celui de Catherine Ruth Solomon.Daté à Montréal, le 1 mai, 1974.Les procureurs de requérant, 57253-20-2-o Spector, Speigbl & Kravetz.Chaya Reigal Solomonovitch Notice is hereby given that Chaya Reigal Solomonovitch, wife separate as to property of Norman Shaffran, residing and domiciled at 5554 Alpine Avenue in the City of Côte St.Luc, District of Montreal, will make an application to the Lieutenant-Governor in Council for an order to change her name to Catherine Ruth Solomon.Dated at Montreal, this 1st day of May, 1974.Spector, Spiegel & Kravetz, 57253-20-2-o Attorneys for Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' aimée, n° SO 3683 Compagnies étrangères Agents Extra-Provincial Companies Agents ALITALIA-LINEE AEREE ÏTALIANE Avis est donné que, par nouvelle procuration en date du 25 janvier 1974, dont une copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, M.Fabrizio Girelli, gérant-général, 1455, Sherbrooke ouest, Montréal, a été nommé en remplacement de M.Enrico Striano, agent principal dans la province, d'« ALITALIA-LINEE AEREE ÏTALIANE », compagnie étrangère, dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 2055, Peel, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives.Albert Jessop.57289-0 PA: 436-60 FOREIGN TOURS, INC.Avis est donné que selon une nouvelle procuration, en date du 27 mars 1974, dont une copie fut envoyée au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, madame Bella Berkovitch, 3450, rue Drummond.appartement 1102, Montréal, a été nommée remplaçante de monsieur James B.Ogilvie à titre d'agent principal dans la province de « FOREIGN TOURS, INC.», une compagnie étrangère dûment autorisée à exercer son commerce dans la province de Québec, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 620.rue Cathcart, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le 3ous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.57288 PA: 24-70 ALITALIA-LINEE AEREE ÏTALIANE Notice is given that, by new power of attorney, dated January 25, 1974, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mr.Fabrizio Girelli, General Manager, 1455 Sherbrooke West, Montreal, was appointed to replace Mr.Enrico Striano, as chief agent in the Province for \"ALITALIA-LINEE AEREE ÏTALIANE\", an extra provincial company duly authorized to carry on business in the Province of Québec pursuant to the provisions of the Extra Provincial Companies Act.The principal office of the company in the Province is located at 2055 Peel, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57289 PA: 436-60 FOREIGN TOURS, INC.Notice is given that, by new power of attorney dated March 27, 1974, a copy of which was sent to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Mrs.Bella Berkovitch, 3450 Drummond Street, apartment 1102, Montreal, was appointed to replace Mr.James B.Ogilvie as chief agent in the Province of \"FOREIGN TOURS, INC.\", an Extra-Provincial Company duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.The principal office of the company in the Province is at 620 Cathcart Street, in the City and Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57288-0 PA: 24-70 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses CESSCO INTERNATIONAL LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « CESSCO INTERNATIONAL LTD.», a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est monsieur Ross T.Clarkson, 630, boulevard Dorchester ouest, 22e étage, Montréal.CESSCO INTERNATIONAL LTD.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CESSCO INTERNATIONAL LTD.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Ross T.Clarkson, 22nd Floor, 630 Dorchester Boulevard West, Montreal. 3684 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol- 'OS, So.SO Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 630, boulevard Dorchester ouest, 22e étage, Montréal, district judiciaire de Montréal.Li sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57195 PA: 3-74 The principal office of the company in the Province is at 22nd Floor, 630 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial district of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195-0 PA: 3-74 KAISER ALUMINUM & CHEMICAL OF CANADA LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « KAISER ALUMINIUM & CHEMICAL OF CANADA LIMITED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux 6ns de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie est M.Guy Laurendeau.8291.Royden Road.Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 8291.Royden Road, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.57195 13554712 KAISER ALUMINIUM & CHEMICAL OF CANADA LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act.\"KAISER ALUMINIUM & CHEMICAL OF CANADA LIMITED\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Guy Lau-rendeau, 8291 Royden Road.Montreal.The principal office of the company in the Province is at 8291 Royden Road.Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195-o 13554712 STANDARD HOSPITAL SUPPLY (EASTERN) LIMITED Avis estdonné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « STANDARD HOSPITAL SUPPLY (EASTERN) LIMTTED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie est M.Frederick S.McRobie.43.Gables Court, Beaconsfield.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 800, Place Victoria, suite 720.Montréal, district judiciaire île Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57195 PA: 19-74 REX CHAINBELT INC.Avis est donné que le 23e jour d'avril 1974.le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé un nouveau permis à « REXNORD INC., l'autorisant à exercer son commerce dans la prnvmoc Min, sun nouveau nom de - RKX CHAIN-BELT INC.», en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères, chapitre 282 des Statuts refondus de 1904.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.o,195 PA: 43-72 STANDARD HOSPITAL SUPPLY (EASTERN) LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"STANDARD HOSPITAL SUPPLY (EASTERN) LIMITED\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Frederick S.McRobie, 43 Gables Court.Beaconsfield.The principal office of the company in the Province is at Suite 720-800 Place Victoria, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195-o PA: 19-74 REX CHAINBELT INC.Notice is given that, on 23rd day of April, 1974, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives, to \"REXNORD INC.\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"REX CHAIN BELT INC.\".pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes.1964.Chapter 282.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.o7195-o PA: 43-72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3685 Curatelle publique Succession Marcel Lalonde Succession de Marcel Lalonde, en son vivant de Montréal décédé le 18 décembre 1970.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57205-o Succession Jean Mercille Succession de Jean Mercille, en son vivant de Montréal décédé le 31 mai 1973.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57206-o Succession Gaston Dancau Succession de Gaston Daneau, en son vivant de 35, rue Giroux, Lauzon, Que., décédé le 13 février 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57286-o Succession Ronald Hillman Succession de Ronald Hillman, en son vivant de 3781, rue Notre-Dame ouest, app.1, Montréal, Que., décédé le 8 février 1970.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que., H2N 1N6 57285-o Public Curator-ship Estate of Marcel Lalonde Estate of Marcel Lalonde, during his lifetime of Montreal, who died on December 18, 1970.Under the authority of the Public Curatorship Act, (Statutes of Québec, 1971, Chapter 81), the undersigned gives notice that he is curator ex-officio to this estate and that he will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given below.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, Québec.H2N 1N6 57205 Estate of Jean Mercille Estate of the late Jean Mercille, in his lifetime of Montreal deceased on May 31st, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Lawrence Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57206-o Estate of Gaston Dancau Estate of the late Gaston Daneau, in his lifetime of 35, Giroux Street, Lauzon, Que., deceased February 13, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57286-o Estate of Ronald Hillman Estate of the late Ronald Hillman, in his lifetime of 3781, Notre-Dame Street West, Apt.1, Montreal, Que., deceased February 8, 1970.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57285-o 3686 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Succession Emile Bourret - Victor Succession de Emile Bourret - Victor, en son vivant de 399 Henri Bourassa ouest, Montreal, Que., décédé le 1 février 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310 St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57202-o Succession Raymond Chouinard Succession de Raymond Chouinard, en son vivant de 262, rue Beaupré, Charlemagne, comté de l'Assomption, Que., décédé le 2 novembre 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2X 1X6 57203-O Succession René Cuilbault Succession de René Cuilbault, en son vivant de 10651 Waverly, Montréal, décédé le 22 janvier 1974.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57204-O Succession Eugène Normandin Succession de Xormandin, Eugène, en son vivant de 111 boul.Lesage, app.8, Duvernay, Laval, décédé le 24 septembre 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57207-e Estate of Emile Bourret - Victor Estate of the late Emile Bourret - Victor, in his lifetime of 399 Henri Bourassa west, Montreal, Que., deceased February 1, 1971.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio> trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St-Laurent, Montreal, Que., H2N 1N6 57202-o Estate of Raymond Chouinard Estate of the late Raymond Chouinard, in his lifetime of 262, Beaupré Street, Charlemagne, county of Assomption, Que., deceased November 2, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to sich estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57203-o Estate of René Cuilbault Estate of the late René Guilbault, in his lifetime of 10651 Waverly, Montreal, deceased January 22th, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St-Laurent, Montreal, Que.H2X 1N6 57204-o Estate of Eugène Normandin Estate of the late Normandin, Eugène, in his lifetime of 111 Blvd.Lesage, Apt.8, Duvernay, Laval, deceased September 24th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent, Montreal, Que.H2N 1N6 57207-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3687 Succession Ludmillia Pecankova Succession de Pecankova, Ludmillia, en son vivant de 11805, rue Ranger, App.11, Montréal, P.Q.décédée le 4 décembre 1970.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Ix>i de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57208-o Succession J.Arthur Porcheron Succession de Porcheron, J.Arthur, en son vivant de 1564 est Mont-Royal, Montréal, Que., décédé le 12 janvier 1974.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57209-o Succession Jean-Marc Rhéaume Succession de Rhéaume, Jean-Marc, en son vivant de 845, 3e Ave.Val D'Or, décédé le 5 septembre 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57210-o Estate of Ludmillia Pecankova Estate of the late Pecankova, Ludmillia, in bis lifetime of 11805, Ranger Street, Apt.11, Montreal, P.Q.deceased December 4, 1970.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentionn-ed address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Quebec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57208-o Estate of J.Arthur Porcheron Estate of the late Porcheron, J.Arthur, in his lifetime of 1564 East, Mont-Royal, Montreal, Que., deceased January 12th 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mentioned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent, Montreal, Que.H2N 1N6 57209-o Estate of Jean-Marc Rhéaume Estate of the late Rhéaume, Jean-Marc, in his lifetime of 845-3e Ave.Val D'Or, deceased September 5th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Quebec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the above-mention-ned address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent, Montreal, Que.H2N 1N6 57210-o Succession Kazimierz Bonczewsk Succession de Kazimierz Bonczewsk, en son vivant de 5679, 15e Avenue, Rosemont, P.Q., décédé le 6 février 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à celte succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 5721 l-o Estate of Kazimierz Bonczewsk Estate of the late Kazimierz Bonczewsk, in his lifetime of 5679, 15th Avenue, Rosemont, P.Q., deceased February 6, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 5721 l-o 3»sS QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, A'o.20 Succession Georges Bishara Succession de Georges Bishara, en son vivant de 1450, rue Fleury, Montréal, Que., décédé le 4 août 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57212-0 Succession René Champagne Succession de René Champagne, en son vivant de 407, rue Mercier, Drummondville, Que., décédé le 22 décembre 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.N2N 1N6 57213-0 Estate of Georges Bishara Estate of the late Georges Bishara, in his lifetime of 1450 Fleury Street East, Montreal, Que., deceased August 4, 1971.« .» The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-o#cJO trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57212-0 Estate of René Champagne Estate of the late René Champagne, in his lifetime of 407 Mercier Street, Drummondville, Que., deceased 22.1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Quebec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57213-0 Succession Antonio Parenteau Succession de Antonio Parenteau, en son vivant de Précieux-Sang, Ville de Bécancour, comté de Nicolet, Que., décédé le 6 août 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers le succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57214-0 Succession Mme Doris Sullivan Succession de Mme Doris Sullivan, en son vivant de 3582, rue Durocher, App.15, Montréal, Que., décédée le 21 juillet 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal, Que.H2N 1N6 572i5.0 Estate of Antonio Parenteau Estate of the late Antonio Parenteau, in his lifetime of Précieux-Sang, City of Bécancour, County of Nicolet, Que., deceased August 6,1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57214-0 Estate of Mrs.Doris Sullivan Estate of the late Mrs.Doris Sullivan, in her lifetime of 3582, Durocher St., Apt.15, Montreal, Que., deceased July 21, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57215-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971,, 106' année, n\" 20 3689 Succession Alice Wood Succession de Alice Wood, en son vivant de 4870 Queen Mary Road, décédée le 16 décembre 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57216-q Arrêté en conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1257-74 Québec, le 3 avril 1974.Présent: Le Lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant la fusion des municipalités scolaires de Bellefeuille, de Lac Abitibi et de La Forêt et la Commission scolaire régionale Lalonde qui cessera d'exister.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation: 1° Que les municipalités scolaires de Bellefeuille, de Lac Abitibi et de La Forêt soient fusionnées en une nouvelle municipalité scolaire pour catholiques au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique comprenant le territoire des cantons et des parties de cantons suivants ainsi que le territoire des corporations municipales et les territoires non organisés situés dans ces cantons et parties de canton: Les cantons Boivin, Paradis, Lemaire, Bourque, Perron, Rousseau, Laver-gne, Vanier, Desmeloizes, Clermont.Chazel, Disson, La Reine, La Sarre, Royal-Roussillon, Languedoc, Roque-maure, Palmarolle, Poularies, Privât, Hébécourt et Duparquet, les lots 1 et 2 des rangs 6 à 10 du canton Guyenne, les lots 1 à 6 inclusivement des rangs 1 à 10 du canton Launay, les lots 50 à 62 inclusivement du rang 9 du canton Destor et les lots 1 à 45 inclusivement des rangs 9 et 10 du canton Aiguebelle; 2° Que la nouvelle municipalité scolaire soit connue sous le nom d'Abitibi et que la corporation ayant autorité sur elle soit connue sous le nom de « La Commission scolaire Abitibi » ; 3° Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1976-1977 la nouvelle municipalité scolaire soit divisée pour fins d'élections en quinze quartiers décrits comme suit: Estate of Alice Wood Estate of the late Alice Wood, in her lifetime of 4870 Queen Mary Road, Montreal, Que., deceased December 16, 1972.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and be will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57216-q Order in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 1257-74 Québec, April 3, 1974.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Connerning the amalgamation of the school municipalities of Bellefeuille, Lac Abitibi and La Forêt and the Lalonde Regional School Board which shall cease to exist.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education : 1.That the school municipalities of Bellefeuille, Lac Abitibi and La Forêt be amalgamated into a new school municipality for Roman Catholics, within the meaning of section 49 of the Education Act, comprising the territory of the following Townships and parts thereof, as well as the territory of the municipal corporations and the unorganized territories located in said Townships and parts thereof: the Townships of Boivin, Paradis, Lemaire, Bourquc, Perron, Rousseau, Lavergne, Vanier, Desmeloizes.Clermont, Chazel, Disson, La Reine, La Sarre, Royal-Roussillon, Languedoc, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, Privât.Hébécourt and Duparquet, lots 1 and 2 of Ranges 6 to 10 in the Township of Guyenne, lots 1 to 6 inclusive of Ranges 1 to 10 in the Township of Launay, lots 50 to 62 inclusive of Range 9 in the Township of Destor and lots 1 to 45 inclusive of Ranges 9 and 10 in the Township of Aiguebelle; 2.That the new school municipality be known under the name of Abitibi and that the corporation having authority over it be known under the name of \"The Abitibi School Board\"; 3.That, until the end of the 1976-1977 school year, the new school municipality be divided, for electoral purposes, into fifteen wards described as follows: 3690 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Le quartier numéro 1 comprend: 1) Le territoire de la municipalité du canton Privât, village; 2) Le territoire de la municipalité de la paroisse de Taschereau.y compris les lots 1 à 6 inclusivement des rangs 1 à 10 inclusivement du canton Launay; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Étienne de Languedoc et les lots 1 et 2 des rangs 6 à 10 du canton Guyenne; 4) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Mathias vAuthier-Nord) ainsi que le territoire ci-dessous qni au point de vue municipal fait partie de la municipalité de la paroisse de Macamic: Les lots 48 à 62 inclusivement du rang 6, les lots 20 à 62 inclusivement du rang 7, les lots 41 à 62 inclusivement du rang 8 et les lots 38 à 62 inclusivement des rangs 9 et 10 du canton Royal-Roussillon; 5) Le résidu des cantons Chazel, Disson et Privât; 6) Les lots 1 à 45 inclusivement des rangs 9 et 10 du territoire non organisé du canton Aiguebelle; Le quartier numéro 2 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Poularies (Ste-Rose); 2) Le territoire de la municipalité d'Authier (St-Judes) ; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de Laferté; 4) Les lots 49 à 62 inclusivement du rang 9 et les lots 17 à 62 inclusivement du rang 10 du territoire non organisé du canton Destor; Le quartier numéro 3 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de la Ville de Macamic; 2) Le territoire de la municipalité de la paroisse de Macamic, excluant le territoire de la paroisse d'Authier-Nord décrit, au quartier numéro 1.Le quartier numéro 4 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de St-Vital de Clermont; 2) Le territoire de la municipalité de Val-St-Gilles; 3) Le territoire de la municipalité de St-Janvier de Chazel qui comprend le territoire non organisé connu sous le nom de St-Eugène de Chazel.Le quartier numéro S comprend : 1 ) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Ephrcm de Val-Paradis; 2) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Camille de Villebois; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Joachim de Beaucanton; 4) Le résidu des cantons Lavergnc, Bourque, Lemaire et Vanier.Ward number 1 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of the Township of Privât, Village; (2) The territory of the Municipality of the Parish of Taschereau, including lots 1 to 6 inclusive of Ranges 1 to 10 inclusive in the Township of Launay; (3) The unorganized territory of the Parish of St.Étienne-de-Languedoc and lots 1 and 2 of Ranges 6 to 10 in the Township of Guyenne; (4) The unorganized territory of the Parish of St.Mathias (Authier-North) as well as the territory mentioned below, which, from a municipal point of view, forms part of the Municipality of the Parish of Macamic: Lots 48 to 62 inclusive in Range 6, lots 20 to 62 inclusive in Range 7, lots 41 to 62 inclusive in Range 8, and lots 38 to 62 inclusive in Range 9 and 10 in the Township of Royal-Roussillon; (5) The remainder of the Townships of Chazel, Disson and Privât; (6) Lots 1 to 45 inclusive of Ranges 9 and 10 in the unorganized territory of the Township of Aiguebelle; Ward number S shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Poularies (Ste.Rose) ; (2) The territory of the Municipality of Authier (St.Judes) ; (3) The unorganized territory of the Parish of Laferté; (4) Lots 49 to 62 inclusive in Range 9 and lots 17 to 62 inclusive in Range 10 of the unorganized territory in the Township of Destor; Ward number 3 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of the Town of Macamic; (2) The territory of the Municipality of the Parish of Macamic, excluding the territory of the Parish of Authier-North described hereinabove in Ward number 1.Ward number 4 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of St.Vital-de-Clermont; (2) The territory of the Municipality of Val-St.Gilles; (3) The territory of the Municipality of St.Janvier-de-Chazel, comprising the unorganized territory known under the name of St.Eugène-de-Chazel.Ward number S shall comprise: (1) The unorganized territory of the Parish of St.Éphrem-dc-Val-Paradis; (2) The unorganized territory of the Parish of St.Camille-de-Villebois; (3) The unorganized territory of the Parish of St.St.Joachim-de-Beaucanton; (4) The remainder of the Townships of Lavergne, Bourque, l-emaire and Vanier. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3691 Le quartier numéro 6 comprend: Le territoire de la Ville minière de Normétal.Le quartier numéro 7 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de St-Lambert-de-Desmeloizes; 2) Le territoire de la municipalité du Village de La Reine; 3) Le territoire de la municipalité de la paroisse de La Reine; 4) Le territoire de la municipalité de Ste-Jeanne-d'Arc-de-Clerval ainsi que le résidu du canton Desmeloizes.Le quartier numéro 8 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Dupuy; 2) Le territoire de la municipalité de Ste-Hélène-de-Mancebourg ainsi que le territoire non organisé connu sous le nom de « Ile Nepawa ».Le quartier numéro 9 comprend : 1) Dans la municipalité de la Ville de La Sarre, la partie nord-est sise au nord de la voie ferrée transcanadienne et à l'est de la rue Principale; 2) Dans la municipalité du canton La Sarre, la partie nord-est sise au nord de la voie ferrée transcanadienne depuis les lots ou parties de lots de canton portant le numéro 19 de chacun des rangs 6 à 10 du canton La Sarre et 1 du canton Clermont et les lots vers l'est jusqu'aux limites est de ladite municipalité en suivant le contour de la ligne separative de la Ville de La Sarre.Le quartier numéro 10 comprend : Dans la municipalité de la Ville de La Sarre, la partie nord-ouest sise au nord de la voie ferrée transcanadienne et à l'ouest de la rue Principale.Le quartier numéro 11 comprend: Dans les municipalités de la Ville de La Sarre et du canton La Sarre, une superficie triangulaire bornée au sud par l'Avenue des Pionniers, à l'est par le point de rencontre de la voie ferrée transcanadienne, au nord par ladite voie ferrée transcanadienne, et à l'ouest par la rivière La Sarre.Le quartier numéro 1S comprend: Dans la municipalité du canton La Sarre, le résidu du territoire sud-ouest à l'intérieur de cette municipalité et qui n'est pas compris dans la délimitation des quartiers Nos 9, 10 et 11.Le quartier numéro 18 comprend : 1) Le territoire de la municipalité de Palmarolle; 2) Le territoire de la municipalité de Ste-Claire-de-Colombourg.Le quartier numéro 14 comprend : 1) Le territoire de la municipalité de Duparquet; 2) Le territoire de la municipalité de Ste-Germaine Boulé.Ward number 6 shall comprise: The territory of the mining Town of Normétal.Ward number 7 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of St.Lambert-de-Dcsméloizes : (2) The territory of the Municipality of the Village of La Reine; (3) The territory of the Municipality of the Parish of La Reine; (4) The territory of the Municipality of Ste.Jeanne-d'Arc-de-Clerval and the remainder of the Township of Desmeloizes.Ward number 8 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Dupuy; (2) The territory of the Municipality of Ste.Hélène-de-Mancebourg as well as the unorganized territory known under the name of \"île Nepawa\".Ward number 9 shall comprise: (1) In the Municipality of the Town of La Sarre, the northeast part lying to the north of the Trans-canadian Railway and to the east of Principale Street; (2) In the Municipality of the Township of La Sarre, the northeast part lying to the north of the Transcana-dian Railway, beginning from the lots or parts of lots of Township bearing number 19 of each of Ranges 6 to 10 of the Township of La Sarre and number 1 of the Township of Clermont and the lots towards the east up to the eastern limits of said Municipality along the line dividing it from the Town of La Sarre.Ward number 10 shall comprise: In the Municipality of the Town of La Sarre, the northwest part lying to the north of the Transcanadian Railway and to the west of Principale Street.Ward number 11 shall comprise: In Ihe Municipalities of the Town of La Sarre and of the Township of La Sarre.a triangular area bounded on the south by Des Pionniers Avenue, on the east by the point of intersection of the Transcanadian Railway, on the north by said Transcanadian Railway, and on the west by La Sarre River.Ward number IS shall comprise: In the Municipality of the Township of La Sarre, the remainder of the southwest territory inside said Municipality and which is not included in the demarcation of wards Nos.9, 10 and 11.Ward number IS shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Palmarolle; (2) The territory of the Municipality of Ste.Claire-de-Colombourg.Ward number 14 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Duparquet; (2) The te-ritory of the Municipality of Ste.Germaine Boulé. 3692 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Le quartier numéro IB comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Roquemaure; 2) Le territoire de la municipalité de St-Laurent; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de Rapide-Danseur; 4) Le résidu des territoires non organisés des cantons Duparquet et Hébécourt.4° Que la Commission scolaire régionale Lalonde dont faisaient partie les commissions scolaires fusionnées, cesse d'exister; et ce, conformément aux articles 46, 49, 50, 64, 90 et 4956 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Le greffier du Conseil exécutif, 57262-0 Julien Chouinard.Ward number 15 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Roquemaure; (2) The territory of the Municipality of St.Laurent; (3) The unorganized territory of the Parish of Rapide-Danseur; (4) The remainder of the unorganized territories of the Township of Duparquet and Hébécourt.4.That the Lalonde Regional School Board of which the amalgamated school boards were part, cease to exist; the foregoing in conformity with sections 46, 49, 50, 64,90 and 4956 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.Julien Chouinard, 57262 Clerk of the Executive Council.Ministère de l'Éducation Department of Education Avis est par la présente donné que, premièrement, les municipalités scolaires de Bellefeuille, de Lac Abitibi et de La Forêt ont été fusionnées pour former une nouvelle municipalité scolaire pour catholiques au seDs de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique, qui sera connue sous le nom de « La commission scolaire Abitibi » ; deuxièmement, la Commission scolaire régionale Lalonde cesse d'exister.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1257-74 en date du 3 avril 1974, dont le texte suit: Concernant la fusion des municipalités scolaires de Bellefeuille, de Lac Abitibi et de La Forêt et la Commission scolaire régionale Lalonde qui cessera d'exister.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation : 1° Que les municipalités scolaires de Bellefeuille, de Lac Abitibi et de La Forêt soient fusionnées en une nouvelle municipalité scolaire pour catholiques au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique comprenant le territoire des cantons et des parties de cantons suivants ainsi que le territoire des corporations municipales et les territoires non organisés situés dans ces cantons et parties de canton: les cantons Boivin, Paradis, Lemaire, Bourque, Perron, Rousseau, Laver-gne, Vanier, Desmeloises, Clermont, Chazel, Disson, La Reine, La Sarre, Royal-Roussillon, Languedoc, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, Privât, Hébécourt et Duparquet, les lots 1 et 2 des rangs 6 à 10 du canton Guyenne, les lots 1 à 6 inclusivement des rangs 1 à 10 du canton Launay, les lots 50 à 62 inclusivement du rang 9 du canton Destor et les lots 1 à 45 inclusivement des rangs 9 et 10 du canton Aiguebellc; 2° Que la nouvelle municipalité scolaire soit connue sous le nom d'Abitibi et que la corporation ayant autorité sur elle soit connue sous le nom de « La Commission scolaire Abitibi » ; Notice is hereby given that, firstly, the school municipalities of Bellefeuille, Lac Abitibi and La Forêt have been amalgamated to constitute a new school municipality for Roman Catholics within the meaning of section 49 of the Education Act, which shall be known under the name of \"The Abitibi School Board\"; secondly, that the Lalonde Regional School Board shall cease to exist.The foregoing, pursuant to Order in Council number 1257-74, dated April 3, 1974, which reads as follows: Concerning the amalgamation of the school municipalities of Bellefeuille, Lac Abitibi and La Forêt and the Lalonde Regional School Board which shall cease to exist.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: 1.That the school municipalities of Bellefeuille, Lac Abitibi and La Forêt by amalgamated into a new school municipality for Roman Catholics, within the meaning of section 49 of the Education Act, comprising the territory of the following Townships and parts thereof, as well as the territory of the municipal corporations and the unorganized territories located in said Townships and parts thereof: the Townships of Boivin, Paradis, lemaire, Bourque.Perron, Rousseau, Laver-gne, Vanier, Desmeloizes.Clermont, Chazel, Disson, La Reine, La Sarre, Royal-Roussillon.Languedoc, Roquemaure.Palmarolle, Poularies, Privât, Hébécourt and Duparquet, lots 1 and 2 of Ranges 6 to 10 in the Township of Guyenne, lots 1 to 6 inclusive of Ranges 1 to 10 in the Township of Launay, lots 50 to 62 inclusive of Range 9 in the Township of Destor ana lots 1 to 45 inclusive of Ranges 9 and 10 in the Township of Aigue-belle; 2.That the new school municipality be known under the name of Abitibi and that the corporation having authority over it be known under the name of \"The Abitibi School Board\"; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 197i, 106' année, n° SO 3693 3° Que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1976-1977 la nouvelle municipalité scolaire soit divisée pour fins d'élections en quinze quartiers décrits comme suit: Le quartier numéro 1 comprend : 1) Le territoire de la municipalité du canton Privât, village; 2) Le territoire de la municipalité de la paroisse de Taschereau, y compris les lots 1 à 6 inclusivement des rangs 1 à 10 inclusivement du canton Launay; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Étienne-de-Languedoc et les lots 1 et 2 des rangs 6 à 10 du canton Guyenne; 4) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Mathias (Authier-Nord) ainsi que le territoire ci-dessous qui au point de vue municipal fait partie de la municipalité de la paroisse de Macamic; Les lots 48 à 62 inclusivement du rang 6, les lots 20 à 62 inclusivement du rang 7, les lots 41 à 62 inclusivement du rang 8 et les lots 38 à 62 inclusivement des rangs 9 et 10 du canton Royal-Roussillon; 5) Le résidu des cantons Chazel, Disson et Privât; 6) Les lots 1 à 45 inclusivement des rangs 9 et 10 du territoire non organisé du canton Aiguebelle; Le quartier numéro S comprend : 1) Le territoire de la municipalité de Poularies (Ste-Rose); 2) Le territoire de la municipalité d'Authier (St-Judes); 3) Le territoire non organisé de la paroisse de La-fer té; 4) Les lots 49 à 62 inclusivement du rang 9 et les lois 17 à 62 inclusivement du rang 10 du territoire non organisé du canton Destor; Le quartier numéro 8 comprend : 1) Le territoire de la municipalité de la ville de Macamic; 2) Le territoire de la municipalité de la paroisse de Macamic, excluant le territoire de la paroisse d'Au-thier-Nord décrit au quartier numéro 1.Le quartier numéro i comprend : 1) Le territoire de la municipalité de St-Vital-de-Clermont; 2) Le territoire de la municipalité de Val-St-Gilles; 3) Le territoire de la municipalité de St-Janvier-de-Chazel qui comprend le territoire non organisé connu sous le nom de St-Eugène-de-Chazel.Le quartier numéro 5 comprend : 1) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Ephrem-de-Val-Paradis ; 2) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Ca-mille-de-Villebois; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de St-Joachim-de-Beaucanton ; 3.That, until the end of the 1976-1977 school year, the new school municipality be divided, for electoral purposes, into fifteen wards described as follows: Ward number 1 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of the Township of Privât, Village; (2) The territory of the Municipality of the Parish of Taschereau, including lots 1 to 6 inclusive of Ranges 1 to 10 inclusive in the Township of Launay; _ (3) The unorganized territory of the Parish of St.Etienne-de-Languedoc and lots 1 and 2 of Ranges 6 to 10 in the Township of Guyenne; (4) The unorganized territory of the Parish of St.Mathias (Authier-North) as well as the territory mentioned below, which, from a municipal point of view, forms part of the Municipality of the Parish of Macamic.Lots 48 to 62 inclusive in Range 6, lots 20 to 62 inclusive in Range 7, lots 41 to 62 inclusive in Range 8, and lots 38 to 62 inclusive in Ranges 9 and 10 in the Township of Royal-Roussillon; (5) The remainder of the Townships of Chazel, Disson and Privât; (6) Lots 1 to 45 inclusive of Ranges 9 and 10 in the unorganized territory of the Township of Aiguebelle; Ward number 2 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Poularies (Ste.Rose); (2) The territory of the Municipality of Authier (St.Judes); (3) The unorganized territory of the Parish of La-ferté; (4) Lots 49 to 62 inclusive in Range 9 and lots 17 to 62 inclusive in Range 10 of the unorganized territory in the Township of Destor; Ward number 3 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of the Town of Macamic; (2) The territory of the Municipality of the Parish of Macamic, excluding the territory of the Parish of Authier-North described hereinabove in Ward number 1.Ward number 4 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of St.Vital-de-Clermont; (2) The territory of the Municipality of Val-St.Gilles; (3) The territory of the Municipality of St.Janvier-de Chazel, comprising the unorganized territory known under the name of St.Eugène-de-Chazel.Ward number 5 shall comprise: (1) The unorganized territory of the Parish of St.Ephrem-de-Val-Paradis; \\2) The unorganized territory of the Parish of St.Camille-de-Villebois; (3) The unorganized territory of the Parish of St.Joachim-de-Beaucanton ; 3694 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO 4) Le résidu des cantons Lavergne, Bourque, Lemai-re et Vanier.Le quartier numéro 6 comprend : Le territoire de la ville minière de Normétal.Le quartier numéro 7 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de St-Lambert-de-Desmeloizes; 2) Le territoire de la municipalité du village de La Reine; 5) Le territoire de la municipalité de la paroisse de La Reine ; 4) Le territoire de la municipalité de Ste-Jeanne-d'Arc-de-Clerval ainsi que le résidu du canton Desmeloizes.Le quartier numéro 8 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Dupuy; 2) Le territoire de la municipalité de Ste-Hélène-de-Mancebourg ainsi que le territoire non organisé connu sous le nom de « île Nepawa ».Le quartier numéro 9 comprend: 1) Dans la municipalité de la ville de La Sarre, la partie nord-est sise au nord de la voie ferrée transcanadienne et à l'est de la rue Principale; 2) Dans la municipalité du canton La Sarre, la partie nord-est sise au nord de la voie ferrée transcanadienne depuis les lots ou parties de lots de canton portant le numéro 19 de chacun des rangs 6 à 10 du canton La Sarre et 1 du canton Clermont, et les lots vers l'est jusqu'aux limites est de ladite municipalité en suivant le contour de la ligne separative de la ville de La Sarre.Le quartier numéro 10 comprend : Dans la municipalité de la ville de La Sarre, la partie nord-ouest sise au nord de la voie ferrée transcanadienne et à l'ouest de la rue Principale.Le quartier numéro 11 comprend: Dans les municipalités de la ville de La Sarre et du canton La Sarre, une superficie triangulaire bornée au sud par l'Avenue des Pionniers, à l'est par le point de rencontre de la voie ferrée transcanadienne, au nord par ladite voie ferrée transcanadienne, et à l'ouest par la rivière La Sarre.Le quartier numéro 1S comprend: Dans la municipalité du canton de La Sarre, le résidu du territoire sud-ouest à l'intérieur de cette municipalité et qui n'est pas compris dans la délimitation des quartiers Nos 9, 10 et 11.Le quartier numéro 13 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Palraarolle; 2) I* territoire de la municipalité de Stc-Claire-de-Colombourg.(4) The remainder of the Townships of Lavergne, Bourque, Lemaire and Vanier.Ward number 6 shall comprise : The territory of the mining Town of Normétal.Ward number 7 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of St.Lambert-de-Desmeloizes; (2) The territory of the Municipality of the Village of La Reine; (3) The territory of the Municipality of the Parish of La Reine; (4) The territory of the Municipality of Ste.Jeanne-d'Arc-de-Clerval and the remainder of the Township of Desmeloizes.Ward number 8 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Dupuy; (2) The territory of the Municipality of Ste.Hélène-de-Mancebourg as well as the unorganized territory known under the name of \"île Nepawa\".Ward number 9 shall comprise: (1) In the Municipality of the Town of La Sarre, the northeast part lying to the north of the Transcanadian Railway and to the east of Principale Street; (2) In the Municipality of the Township of La Sarre, the northeast part lying to the north of the Transcanadian Railway, beginning from the lots or parts of lots of Township bearing number 19 of each of Ranges 6 to 10 of the Township of La Sarre and number 1 of the Township of Clermont and the lots towards the east up to the eastern limits of said Municipality along the line dividing it from the Town of La Sarre.Ward number 10 shall comprise: In the Municipality of the Town of La Sarre, the northwest part lying to the north of the Transcanadian Railway and to the west of Principale Street.Ward number 11 shall comprise: In the Municipalities of the Town of La Sarre and of the Township of La Sarre, a triangular area bounded on the south by Des Pionniers Avenue, on tbe east by the point of intersection of the Transcanadian Railway, on the north by said Transcanadian Railway, and on the west by La Sarre River.Ward number IS shall comprise: In the Municipality of the Township of La Sarre, the remainder of the southwest territory inside said Municipality and which is not included in the demarcation of wards Nos.9, 10 and 11.Ward number 13 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Palmarolle; (2) The territory of the Municipality of Ste.Claire-de-Colombourg. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3695 Le quartier numéro 14 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Duparquet; 2) Le territoire de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé.Le quartier numéro 15 comprend: 1) Le territoire de la municipalité de Roquemaure; 2) Le territoire de la municipalité de St-Laurent; 3) Le territoire non organisé de la paroisse de Rapide-Danseur; 4) Le résidu des territoires non organisés des cantons Duparquet et Hébécourt.4° Que la Commission scolaire régionale Lalonde dont faisaient partie les commissions scolaires fusionnées, cesse d'exister; et ce, conformément aux articles 46, 49, 50, 64, 90 et 4956 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Ce changement prendra effet le premier juin 1974 pour les fins d'élection, et le premier juillet pour loutes autres fins.Le ministre de l'éducation, 57263-20-2-o François Cloutier.Proclamation Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.À tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Dasserat, comprenant le bloc 29, située dans la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagnée d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, à Rouyn; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, et, en Ward number 14 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Duparquet; (2) The territory of the Municipality of Ste.Germaine Boulé.Ward number 16 shall comprise: (1) The territory of the Municipality of Roquemaure; (2) The territory of the Municipality of St.Laurent; (3) The unorganized territory of the Parish of Rapide-Danseur; (4) The remainder of the unorganized territories of the Townships of Duparquet and Hébécourt.4.That the Lalonde Regional School Board of which the amalgamated school boards were part, cease to exist; the foregoing in conformity with sections 46, 49, 50, 64,90 and 4956 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.This change shall take effect on the first of June 1974 for electoral purposes and on the first of July 1974 for all other purposes.François Cloutier, 57263-20-2 Minister of Education.Proclamation Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Dasserat, comprising block 29, located in the Rouyn-Noranda Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Rouyn-Noranda Registration Division Office, in Rouyn by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Rouyn-Noranda Registration Division, and, at 3696 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladjte partie du canton de Dasserat.À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1480-74, du 24 avril 1974, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 et 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent», qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, à Rouyn, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Dasserat, comprenant le bloc 29, située dans la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Dasserat; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., ch., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-quatrième jour d'avril en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre, Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 René Langevin.Folio: 218 57254-0 the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Dasserat.Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 1480-74, dated April 24, 1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title' of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Rouyn-Noranda Registration Division Office, in Rouyn, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Dasserat, comprising block 29 located in the Rouyn-Noranda Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisiens of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Dasserat; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly ; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed ; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-fourth day of April in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Our Reign.By command, René Langevin, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 218 57254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, u° 20 3697 Sociétés coopératives agricoles Cooperative Agricultural Associations SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ALBERTVILLE (Loi des sociétés coopératives agricoles) Avis est donné que la « SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ALBERTVILLE », dont le siège social était situé à St-Raphaël-d'Albertville, dans le district électoral de Matapédia, a été dissoute le 4 avril 1974, et ce conformément aux dispositions de la Loi des société coopératives agricoles et de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57283-0 Albert Jessop.SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ALBERTVILLE (Cooperative Agricultural Associations Act) Notice is given that \"SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'ALBERTVILLE\", whose head office was located in St.Raphaël-d'Albertville, in the Electoral District of Matapédia, was dissolved on April 4, 1974, the foregoing, in conformity with the provisions of the Cooperative Agricultural Associations Act and of the Winding-Up Act.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57283 Companies and Cooperatives.Syndicats professionnels Professional Syndicates SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU LANAUDIERE (S.E.L.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 11 mars 1974, il a autorisé le changement de nom de « ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU LANAUDIERE», dont la constitution, sous le nom originaire de « ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE LANAUDIERE », a été autorisée le 6 décembre 1963, et dont le siège social est situé à Joliette, en celui de «SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU LANAUDIERE (S.E.L.) », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57273-0 SP: 75-63 SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 12 mars 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE», avec siège social situé à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57274 SP: 74-73 SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU LANAUDIERE (S.E.L.) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on March 11, 1974, the \"ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU LANAUDIERE\", incorporated on December 6, 1963, under the original name of \"ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE LANAUDIERE, and having its head office in Joliette, has been authorized to change its name to that of \"SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU LANAUDIERE (S.E.L.)\", the foregoing in conformity with the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57273 SP: 75-63 SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on March 12, 1974, he has authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE\", having its head office in Sherbrooke, Judicial District of Saint-François.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57274 SP: 74-73 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.Avis est par les présentes donné, tel qu'il est prévu par l'article 276 de la Loi des assurances de Québec, que « CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY LNC.», à une assemblée générale spéciale des membres tenue le 7 mai 1974, a (1) décidé de liquider ses affaires, (2) nommé le liquidateur M.(iérard Démets, domicilié à 97 est, rue Principale, Farnham, et (3) fixé au 8 juin 1974 la date à laquelle la société cessera de verser des bénéfices.Donné en la Cité de Farnham, ce 8e jour de mai 1971.Le secretaire, 57275-0 Gérard Demers.Notice is hereby given, as provided in section 276 of the Québec Insurance Act, that the \"CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.\", at a special general meeting of its members, held on 7th of May 1974, has (1) decided to liquidate its business, (2) named liquidator Mr.Gérard Demers, domiciled at 97 Principale Street East, Farnham, and (3) fixed the 8th of June 1974 as the date upon which its benefits will cease to be paid.Given at Farnham, this Sth day of May, 1974.Gérard Demers, 57275-0 Secretary.CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.Avis est par les présentes donné qu'à une assemblée générale spéciale des membres de « CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.», tenue le 7 mai 1974, le soussigné, domicilié à 97 est, rue Principale.Farnham, a été nommé liquidateur de ladite société, conformément aux dispositions de l'article 276 de la Loi des assurances de Québec.Toute réclamation contre ladite société devra être attestée sous serment et produite entre mes mains dans les trente jours du présent avis.Donné conformément aux dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, ce 8e jour de mai 1974.Le liquidateur.57276-0 Gérard Demers.Notice is hereby given that on the 7th May 1974.at a special general meeting of the memlwrs of the \"CANADIAN RAILWAYS BENEFIT SOCIETY INC.\", the undersigned, domiciled at 97 Principale Street East, Farnham, was appointed liquidator of the affaires of the said society pursuant to the provisions of section 276 of the Québec Insurance Act.Any claim against the said society must be sworn to and filed with me within the thirty days following the present notice.Given pursuant to article 872 of the Code of Civil Procedure, this 8th day of May 1974.Gérard Demers, 57276-o Liquidator.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on HOPITAL CLOUTIER Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'avril 1974, convertissant « HOPITAL CLOUTIER », constituée le 19 septembre 1963, en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi relative à la constitution en corporation des évêques catholiques romains, chapitre 76 des lois de 1950, en un établissement public sous le nom de « HOPITAL CLOUTIER».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE HOSPITALIER ».Le siège social de l'établissement est à Cap-de-la-Madelcine, district judiciaire de Trois-Rivières.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-0 13545272 HOPITAL CLOUTIER The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that, pursuant to sec-sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated April 10, 1974, converting \"HOPITAL CLOUTIER\", incorporated on September 19, 1963, pursuant to the provisions of section 20 of the Act respecting the incorporation of Roman Catholic Bishops, Chapter 76 of the Statutes of 1950, into a public establishment under the name of \"HOPITAL CLOUTIER\".This public establishment shall be classified as a: \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of said establishment is in Cap-de-la-Madcleine, Judicial District of Three-Rivers.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 13545272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3699 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES SECTEUR BRANDON Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 41 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes supplémentaires eu date du 17e jour d'avril, 1974 modifiant les lettres patentes émises le 19 septembre 1973.Le ministre des institutions finacières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-0 SS: 59-73 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES SECTEUR BRANDON The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 41 and 47 of the Act respecting health services and social services.Statutes of 1971, Chapter 48, be has granted supplementary letters patent, dated the 17th day of April, 1974, amending the letters patent issued on September 19, 1973.William Tetley, M inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 SS: 59-73 CENTRE HOSPITALIER SAINTE-FAMILLE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'avril 1974, convertissant « HOPITAL SAINTE-FAMILLE DE VILLE-MARIE », constituée le 27 novembre 1963, en vertu des dispositions de l'article 20 de la Loi relative à la constitution en corporation des évêques catholiques romains, chapitre 76 des lois de 1950, en un établissement public sous le nom de « CENTRE HOSPITALIER SAINTE-FAMILLE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE HOSPITALIER ».Le siège social de l'établissement est à Ville-Marie, district judiciaire de Témiscamingue.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-o 13543915 CENTRE HOSPITALIER SAINTE-FAMILLE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that, pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated April 17, 1974, converting \"HOPITAL SAINTE-FAMILLE DE VILLE-MARIE\", incorporated on November 27, 1963, pursuant to the provisions of section 20 of the Act respecting the incorporation of Roman Catholic Bishops, Chapter 76 of the Statutes of 1950, into a public establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER SAINTE-FAMILLE\".This public establishment shall be classified as: \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of said establishment is in Ville-Marie, Judicial District of Témiscamingue.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 13543915 CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 17e jour d'avril 1974, convertissant « HOPITAL GENERAL DU CHRIST-ROI DE VERDUN », constituée le 31 mars 1960, en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi modifiant la charte de La Communauté des Soeurs de la Charité de la Providence, chapitre 176 des lois de 1958-1959, en un établissement public sous le nom de « CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE HOSPITALIER ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-o 13549795 CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that, pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated April 17, 1974, converting \"HOPITAL GENERAL DU CRHIST-RQI DE VERDUN\", incorporated on March 31, 1960, pursuant to the provisions of section 14 of the Act to amend the charter of La Communauté des Soeurs de la Charité de la Providence, Chapter 176 of the Statutes of 1958-1959, into a public establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN\".This establishment shall be classified as a: \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of the establishment is in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 13549795 3700 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.IPG, So.20 CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE QUEBEC CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE QUEBEC Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 41 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 3e jour d'avril 1974, modifiant les lettres patentes émises le 30 mai 1973.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-o SS: 31-73 VILLA PABOS Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 10e jour d'avril 1974, convertissant « VILLA MGR SEVIGNY DE CHANDLER INC.», constituée le 23 juillet 1969, en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, en un établissement public sous le nom de « VILLA PABOS ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Chandler, district judiciaire de Gaspé.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57195-o 13543905 The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under sections 41 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted supplementary letters patent, dated the 3rd day of April, 1974, amending the letters patent issued on May 30, 1973.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 SS: 31-73 VILLA PABOS The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services.Chapter 48 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated April 10, 1974, converting \"VILLA MGR SEVIGNY DE CHANDLER INC.\", incorporated on July 23, 1969, under Part III of the Companies Act, into a public establishment under the name of \"VILLA PABOS\".This public establishment shall be classified as a: \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is in Chandler, Judicial District of Gaspé.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57195 13543905 Ministère des institutions Department of Financial financières, compagnies Institutions, Companies et coopératives and Cooperatives Assurances Insurance CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY Avis d'émission de permis et de certificat d'enregistrement Avis est donné par les présentes que « CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY », enregistrée sous le numéro 762 a obtenu le permis et le certificat d'enregistrement numéro 1774 qui l'autorise à compter du 12 novembre 1973, a effectuer dans la province des contrats relatifs aux genres d'assurance suivants: Vie; Accident; Maladie.Le siège social de la compagnie est situé à 8301, avenue Maryland.St-Louis, Missouri, Etats-Unis cl Amérique.compagnie a nommé monsieur Richard Hinton, 3869.rue des Sources, Dollard-des-Ormeaux 980, son procureur dans la province.CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY Notice of Issue of License and Certificate of Registration Notice is hereby given that \"CHARTER NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY\", registered under number 762, has obtained the license and certificate of registry number 1774, authorizing it, as from the 12th of November 1973 to undertake in the Province contracts of insurance in the following classes: Life; Accident and Sickness.The head office of the company is situated at 8301, Maryland Avenue, St.Louis, Missouri, United States of America.The company has appointed Mr.Richard Hinton, 3869 des Sources Street, Dollard-des-Ormeaux 980, its attorney in the Province. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3701 Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 19 décembre 1973.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances, 57260-20-2-o Roger-A.Camaraire.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 19th of December 1973.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 57260-20-2-o Superintendent of Insurance.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for La Commission scolaire de Cowansville Siège social: 319, rue Sud, CP.20, Cowansville, (Missisquoi), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné D.G.Bradford, directeur-général.Centre administratif, 319, rue Sud, Case postale 20, Cowansville, comté de Missisquoi, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi, le 3 juin 1974, pour l'achat de $126,000 d'obligations de la commission scolaire de Cowansville, datées du 15 juin 1974 et remboursables en série du 15 juin juin 1975 au 15 juin 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $126,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 06 1975.$ 2,500 15 06 1976 .2,500 15 06 1977 .3,000 15 06 1978 .3,000 15 06 1979 .3,500 15 06 1980 .3,500 15 06 1981.4,000 15 06 1982 .4,500 15 06 1983.5,000 15 06 1984.5,000 La commission scolaire de Cowansville se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (chapitre 63 des lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.The Cowansville School Board Head Office: 319 South (Sud) Street, Post Office Box 20, Cowansville, (Missisquoi), P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, D.G.Bradford, Director-General, at the Administration Centre, 319 South (Sud) Street, Post Office Box 20, Cowansville, County of Missisquoi, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, June 3, 1974, for the purchase of a bond issue of $126,000 for the Cowansville School Board, dated June 15, 1974, and redeemable serially from June 15, 1975 to June 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on June 15th and December 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1974.Redemption table \u2014 $126,000 \u2014 20 years Date Capital 15 06 1985.$ 6,000 15 06 1986 .6,500 15 06 1987 .7,000 15 06 1988.7,500 15 06 1989.8,000 15 06 1990 .9,000 15 06 1991.10,000 15 06 1992.11,000 15 06 1993.11,500 15 06 1994.13,000 The Cowansville School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required. 3702 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol- 106, No.SO En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3\" Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $13,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 1994.Cependant, les soumissons ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $13,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Cowansville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution suivante: 25 septembre 1973 \u2014 $126,000 \u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, lundi, le 3 juin 1974, Centre administratif, 319, rue Sud, Case postale 20, Cowansville, comté de Missisquoi, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Cowansville, (Comté de Missisquoi), ce 8 mai 1974.Le directeur général, D.G.Bradford.Centre administratif, 319, rue Sud, Case postale 20, Cowansville, (Missisquoi), Que.Téléphone: 263-3722, 263-3727, code 514.57259-0 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $13,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of June 15, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $13,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Cowansville School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after June 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolution : September 25, 1973 \u2014 $126,000 \u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, June 3, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Administration Centre, 319 South (Sud) Street, Post Office Box 20, Cowansville, County of Missisquoi, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Cowansville, (County of Missisquoi), May 8, 1974.D.G.Bradford, Director-General.Administration Centre, 319 South (Sud) Street, Post Office Box 20, Cowansville, (Missisquoi), Que.Telephone: 263-3722, 263-3727, code 514.37259 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3703 Ville de Saint-Félicien Comté de Roberval Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné .T.A.Blouin, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 1058, Boulevard Sacré-Coeur, C.P.880, St-Félicien, comté de Roberval, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 4 juin 1974, pour l'achat de $337,500 d'obligations de la ville de St-Félicien, comté de Roberval, datées du 1er juillet 1974 et remboursables en série du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $337,500 \u2014 20 ans Date Capital 01 07 1975.$13,500 01 07 1976.15.000 01 07 1977.16,500 01 07 1978.17,500 01 07 1979.19.0C0 01 07 1980.16,000 01 07 1981.16,500 01 07 1982.18,500 01 07 1983.19,500 01 07 1984.22.000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $22,500 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Town of St.Félicien County of Roberval Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, J.A.Blouin, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 1058 Sacré-Coeur Boulevard, Post Office Box 880, St.Félicien, County of Roberval, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 4, 1974, for the purchase of a bond issue of $337,500 for the Town of St.Félicien, County of Roberval, dated July 1, 1974 and redeemable serially from July 1, 1975 to July 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9% nor more than 10%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 1, 1974.Redemption table \u2014 $837,500 \u2014 SO years Date Capital 01 07 1985.$11,000 01 07 1986.12,000 01 07 1987.13,500 01 07 1988.14,500 01 07 1989.15,000 01 07 1990.16,000 01 07 1991.18,000 01 07 1992.20,000 01 07 1993.21,000 01 07 1994.22,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $22,500 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 1,1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. 3704 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol- 106, No.SO L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $22,500, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt La ville de Saint-Félicien s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 511 \u2014 $32.000 \u2014 aqueduc égouts et voirie; 545 \u2014 $11,400 \u2014 éclairage; 546 \u2014 $29,100 \u2014 voirie; 581 \u2014 $1,200 \u2014 aqueduc et égouts; 590 \u2014 $11,000 \u2014 aqueduc et égouts; 597 \u2014 $77,600 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 599-A \u2014 $11.000 \u2014 bâtisses pour les loisirs; 60S \u2014 $11,500 \u2014 voirie; 611 \u2014 $31,000 \u2014 voirie et éclairage; 613 \u2014 $9,000 \u2014 planification; 621 \u2014 $82.800 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 622 \u2014 $19,200 \u2014 achat de machinerie; 624 \u2014 $10,700 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, mardi, le 4 juin 1974, Hôtel de ville.1058.boulevard Sacré-Coeur, case postale 880, St-Félicien, comté de Roberval, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Félicien (Comté de Roberval), ce 13 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, J.A.Blouin.Hôtel de ville, 1058, boulevard Sacré-Coeur, Case postale 880, St-Félicien, (Roberval) P.Q.Téléphone: 679-0251, code 418.57302-o Commission scolaire régionale Henri-Bourassa Siège social: 500, Boul.Paquette, Mont-Laurier, comté de Labelle, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gilbert Joly, directeur général, jusqu'à 5 heures de 1 après-midi, au Centre administratif.500.Boulevard Paquette, Mont-Laurier, comté de Labelle, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir, Ecole polyvalente de St-Joseph-de-Mont-Laurier, 565, rue de la Montagne.Mont-Laurier, comté de Labelle, P.Q., mercredi, le 5 juin 1974, pour l'achat de $400,000 d'obligations de The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $22,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July lst'of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Félicien agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 511 \u2014 $32,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 545 \u2014 $11,400 \u2014 lighting; 546 \u2014 $29,100 \u2014 roads; 581 \u2014 $1,200 \u2014 waterworks and sewers; 590 \u2014 $11,000 \u2014 waterworks and sewers: 597 \u2014 $77,600 \u2014 waterworks, sewers and roads; 599-A \u2014 $11,000 \u2014 recreational building; 608 \u2014 $11,500 \u2014 roads; 611 \u2014 $31,000 \u2014 roads and lighting: 613 \u2014 $9,000 \u2014 planning; 621 \u2014 $82.800 \u2014 waterworks, sewers and roads; 622 \u2014 $19.200 \u2014 purchase of machinery; 624 -$10,700 \u2014roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 4, 1974, at the Town Hall, 1058 Sacré-Coeur Boulevard, Post Office Box 880, St.Félicien, County of Roberval, P.Q.St.Félicien (County of Roberval), May 13, 1974.J.A.Blouin, Secretary-Treasurer.Town Hall, 1058 Sacré-Coeur Boulevard, Post Office Box 880, St.Félicien, (Roberval), P.Q.Telephone: 679-0251, code 418.57302 The Henri Bourassa Regional School Board Head Office: 500 Paquette Boulevard, Mont-Laurier County of Labelle, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Gilbert Joly, Director-General, until 5:00 o'clock p.m., at the Administration Centre, 500 Paquette Boulevard, Mont-Laurier, County of Labelle, P.Q.and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the St.Joseph-de-Mont-Laurier, Comprehensive School, 565 De la Montagne Street, Mont-Lauiier, County of Labelle, P.Q., on Wesnesday, June 5, 1974, for the purchase of a bond issue of $400,000 for the Henri- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3705 la commission scolaire régionale Henri-Bourassa, datées du 1er juillet 1974 et remboursables en série du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudicalion seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $400,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 07 1975.$ 8,000 01 07 1976.9,000 01 07 1977.9,000 01 07 1978.10,000 01 07 1979.11,000 01 07 1980.12.000 01 07 1981.13,000 01 07 1982.14.000 01 07 1983.16,000 01 07 1984.17,000 La commission scolaire régionale Henri-Bourassa se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fideicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $40,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans Bourassa Regional School Board, dated July 1, 1974 and redeemable serially from July, 1, 1975 to July, 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9% nor more than 10%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 1,1974.Redemption table \u2014 $400,000 \u2014 20 years Date Capital 01 07 1985.$18,000 01 07 1986 .20,000 01 07 1987.22,000 01 07 1988 .24,000 01 07 1989 .26,000 01 07 1990.29,000 01 07 1991.31,000 01 07 1992 .34,000 01 07 1993.37,000 01 07 1994 .40,000 The Henri-Bourassa Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board'Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payement, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $40,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemtion table appearing in this notice, and starting with the last vears of redemption excluding the maturity of July 1, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipu- 3706 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No SO les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $40,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale Henri-Bourassa s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution suivante: 3 avril 1974 \u2014 $400,000 \u2014 dépenses d'immobilisations 1972-73.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mercredi, le 3 juin 1974, Ecole polyvalente de St-Joseph-de-Mont-Laurier, 565, rue de la Montagne, Mont-Laurier, comté de Labelle, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Mont-Laurier, (Comté de Labelle), ce 8 mai 1974.Le directeur général, Gilbert Joly.Centre administratif, 500 boulevard Paquette, Mont-Laurier, (Labelle), P.Q.Téléphone : 623-1525, code 819.57258-o Ville de Malartic Comté de Rouyn-.N'oranda Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Réjean Hamel, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 901, rue Royale, Case Postale 3090, Malartic, comté de Rouyn-Noranda, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 3 juin 1974, pour l'achat de $533,000 d'obligations de la ville de Malartic, comté de Rouyn-Noranda, datées du 15 juin 1974 et remboursables en série du 15 juin 1975 au 15 juin 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.lated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.l , The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $40,000, and the said sur plus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Henri-Bourassa Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after July 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: April 3, 1974 \u2014 $400,000 \u2014 capital expenditure for 1972-1973.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, June 5, 1974, at the St.Joseph-de-Mont-Laurier Comprehensive School, 565 De la Montagne Street, Mont-Laurier, County of Labelle, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Mont-Laurier, (County of Labelle), May 8, 1974.Gilbert Joly, Director-General.Administration Centre, 500 Paquette Boulevard, Mont-Laurier (Labelle), P.Q.Telephone: 623-1525, code 819.57258 Town of Malartic County of Rouyn-Noranda Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Réjean Hamel, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 901 Royale Street, Post Office Box 3090, Malartic, County of Rouyn-Noranda, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, June 3, 1974, for the purchase of a bond issue of $533,000 for the Town of Malartic, County of Rouyn-Noranda, dated June 15, 1974, and redeemable serially from June 15, 1975 to June 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on June 15th and December 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3707 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $533,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 06 1975.$ 17,000 15 06 1976.18,000 15 06 1977 .20,000 15 06 1978 .22,000 15 06 1979 .24,000 15 06 1980.26,000 15 06 1981.29,000 15 06 1982 .32,000 15 06 1983 .35,000 15 06 1984 .38,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $28,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juin 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $28.000.et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Malartic s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1974.Redemption table \u2014 $533,000 \u2014 SO years ¦ Date Capital 15 06 1985.$ 25,000 15 06 1986.28,000 15 06 1987 .30,000 15 06 1988 .33,000 15 06 1989 .36,000 15 06 1990 .20,000 15 06 1991.22,000 15 06 1992 .24,000 15 06 1993 .26,000 15 06 1994 .28,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $28,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of June 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $28,000.and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Malartic agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after June 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue. 3708 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971,, Vol.106, No.SO Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 181 \u2014 $275,000 \u2014 construction d'une piscine intérieure à la polyvalente de Malartic; 197 \u2014 $54,000 \u2014 aqueduc et égouts; 206 \u2014 $48,000 \u2014 achat d'équipement; 208 \u2014 $120,000 \u2014 travaux d'aménagement à Caréna; 210 \u2014 $36,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, lundi, le 3 juin 1974.Hôtel de ville, 901, rue Royale, Case Postale 3090, Malartic, comté de Rouyn-Noranda, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Malartic (Comté de Rouyn-Noranda), ce 9 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, Réjean Hamel.Hôtel de ville, 901, rue Royale, Case Postale 3090, Malartic, (Rouvn-Noranda) P.Q.Téléphone : 757-3611, code 819.57268-o Cité de Lauzon Comté de Lévis Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription ' Soumissions pour obligations > seront reçues par la soussignée Mme Suzanne Carrier, greffier.Hôtel de Ville, 304, rue St-Joseph-Est, Lauzon, comté de Lévis, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 4 juin, 1974, pour l'achat de $323.000 d'obligations de la cité de Lauzon, comté de Lévis, datées du 1er juillet 1974 et remboursables en série du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $323,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 07 1975.$ 6,500 01 07 1976 .7,500 01 07 1977.8.000 01 07 1978 .9.000 01 07 1979 .9,500 01 07 1980.10,500 01 07 1981.11,500 01 07 1982.12,500 01 07 1983.13,500 01 07 1984.15,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 181 \u2014 $275,000 \u2014 construction of an indoor swimming pool at the Malartic Comprehensive School; 197 \u2014 $54,000 \u2014 waterworks and sewers; 206 \u2014 $48,000 \u2014 purchase of equipment; 208 \u2014 $120,000 \u2014 developments works at the arena; 210 \u2014 $36,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of tbe Council, or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Monday, June 3, 1974, at the Town Hall, 901 Royale Street, Post Office Box 3090, Malartic, County of Rouyn-Noranda, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest of any of the tenders.Malartic, (County of Rouyn-Noranda), May 9,1974.Réjean Hamel, Secretary-Treasurer.Town Hall, 901 Royale Street, P.O.Box 3090, Malartic, (Rouyn-Noranda, P.Q.Telephone : 757-3611, code 819.57268 City of Lauzon County of Levis Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Suzanne Carrier, City Clerk, at the City Hall, 304 St.Joseph Street East, LauzoD, County of Lévis, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 4, 1974, for the purchase of a bond issue of $323,000 for the City of Lauzon, County of Levis, dated July 1,1974, and redeemable serially from July 1, 1975 to July 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 1st and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 1, 1974.Redemption table \u2014 SSSSfiOO \u2014 SO years Date Capital 01 07 1985.$14,000 01 07 1986.15,500 01 07 1987.17,000 01 07 1988.18,500 01 07 1989 .20,500 01 07 1990.22 000 01 07 1991.24,500 01 07 1992 .26,500 01 07 1993 .29,000 01 07 1994 .32,000 Moreover, the following terms and conditions oi will be considered: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3709 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $32,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $32,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Lauzon s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 579 \u2014 $235,000 \u2014 consolidation de déficit: 581 \u2014 $16,200 \u2014 égouts; 583 \u2014 $14,800 \u2014 achat de machineries; 585 \u2014 $57,000 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue mardi, le 4 juin 1974, à 8 heures du soir, Hôtel de Ville, 304, rue St-Joseph-Est, Lauzon, comté de Lévis, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Lauzon (Comté de Lévis), ce 10 mai 1974.Le greffier, Mme Suzanne Carrier.Hôtel de Ville, 304, rue St-Joseph-Est, Lauzon, tLévis), P.Q.Téléphone: 837-5801, code 418.57267-0 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $32,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 1, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $32,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Lauzon agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 1st, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 579 \u2014 $235,000 \u2014 consolidation of deficit; 581 \u2014 $16,200 \u2014 sewers; 583 \u2014 $14,800 \u2014 purchase of equipment; 585 \u2014 $57,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case may be, to be held on Tuesday, June 4, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the City Hall, 304 St.Joseph Street East, Lauzon, County of Levis, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Lauzon (County of Levis), May 10, 1974.Mrs.Suzanne Carrier, City Clerk.City Hall, 304 St.Joseph Street East, Lauzon (Levis), P.Q.Telephone: 837-5801, code 418.57267 3710 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 La commission scolaire Monseigneur Vachon Siège social: 400, rue St-Cyrille, St-Raymond, comté de Portneuf, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » sreont reçues par la soussignée Madame Pauline Guay-Brousseau, directrice générale, Centre administratif, 400, rue St-Cyrille, St-Raymond, comté de Portneuf, P.Q., jusqu à 11 heures a.m., lundi, le 3 juin 1974, pour l'achat de $430,000 d'obligations de la commission scolaire Monseigneur Vachon, datées du 15 juin 1974 et remboursables en série du 15 juin 1975 au 15 juin 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Le taux d intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juin 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $430,000 \u2014 10 ans Date Capital 15 06 1975 .$28,000 15 06 1976 .30,000 15 06 1977 .33,000 15 06 1978 .36,000 15 06 1979 .40,000 La commission scolaire Monseigneur Vachon, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire Monseigneur Vachon s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché The Monseigneur Vachon School Board Head Office: 400 St.Cyrille Street, St.Raymond, County of Portneuf, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Pauline Guay-Brousseau, Director-General, at the Administration Centre, 400 St.Cyrille Street, St.Raymond, County of Portneuf, P.Q., until 11:00 o'clock a.m., on Monday, June 3, 1974, for the purchase of a bond issue of $430,000 for the Monseigneur Vachon School Board, dated June 15, 1974, and redeemable serially from June 15, 1975 to June 15, 1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on June 15th and December 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 15, 1974.Redemption table \u2014 $430,000 \u2014 10 years Date Capital 15 06 1980 .$44,000 15 06 1981 .48,000 15 06 1982 .52,000 15 06 1983 .57,000 15 06 1984 .62,000 The Monseigneur Vachon Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Monseigneur Vachon School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO canadien dans les soixante jours à compter du 15 juin 1974, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 11 février 1974 \u2014 $430,000 \u2014 construction d'un gymnase à Pont-Rouge.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 11 heures a.m., lundi, le 3 juin 1974, Centre administratif, 400, rue St-Cyrille, St-Raymond, comté de Portneuf, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.St-Raymond (Comté de Portneuf), ce 10 mai 1974.La directrice générale, Mme Pauline Guay-Brousseau.Centre administratif, 400, rue St-Cyrille, St-Raymond (Portneuf), P.Q.Téléphone: 337-6717, code 418.57269-0 Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges Siège social: 3255, rue Foucher, Trois-Rivières, (Trois-Rivières), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription < Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Robert Lemieux, directeur général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi, Centre administratif, 3255, rue Foucher, Trois-Rivières, comté de Trois-Rivières, P.Q., et par après jusqu'à 8 heures du soir.Polyvalente du Cap-ie-la-Madeleine, 501, rue des Érables, Cap-de-la-Madeleine, comté de Trois-Rivières, P.Q., mercredi, le 5 juin 1974, pour l'achat de $2,000,000 d'obligations de la commission scolaire régionale des Vieilles-Forges, datées du 1er juillet 1974 et remboursables en série du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $2,000,000 \u2014 20 ans \tDate\tCapital 01\t07 1975.\t.8 37,000 01\t07 1976.\t.41,000 01\t07 1977.\t.44,000 01\t07 1978.\t.48,000 01\t07 1979.\t.53,000 01\t07 1980.\t.58,000 01\t07 1981.\t.64,000 01\t07 1982.\t.70,000 01\t07 1983.\t.76,000 01\t07 1984.\t.84,000 the sixty days upon, from and after June 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated February 11, 1974 \u2014 $430,000 \u2014 construction of a gymnasium in Pont-Rouge.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commission to be held at 11:00 o'clock a.m., on Monday, June 3, 1974, at the Administration Centre, 400 St.Cyrille Street, St.Raymond, County of Portneuf, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.St.Raymond (County of Portneuf), May 10, 1974.Mrs.Pauline Guay-Rousseau, Director General.Administration Centre, 400 St.Cyrille Street, St.Raymond (Portneuf), P.Q.Telephone : 337-6717, code 418.57269 The Vieilles-Forges Regional School Board Head Office: 3255 Foucher Street, Trois-Rivières, Trois-Rivières, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Robert Lemieux, Director General, on Wednesday, June 5, 1974, until 4.30 o'clock p.m., and the Administration Centre, 3255 Foucher Street, Trois-Rivières, County of Trois-Rivières, P.Q.and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Comprehensive School of Cap-de-la-Madeleine, 501 des Érables Street, Cap-de-la-Madeleine, County of Trois-Rivières, P.Q.for the purchase of a bond issue of $2,000,000 for the Vieilles-Forges Regional School Board, dated July 1, 1974 and redeemable serially from July 1, 1975 to July 1, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 1st, and July 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 1, 1974, Redemption table \u2014 $2,000,000 \u2014 20 years Date Capital 01 07 1985.$ 92,000 01 07 1986.100,000 01 07 1987.110,000 01 07 1988.120,000 01 07 1989.132,000 01 07 1990.144,000 01 07 1991.158,000 01 07 1992.173,000 01 07 1993.189,000 01 07 1994.207,000 3712 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.so La commission scolaire régionale des Vieilles-Forges se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'Education d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des Finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $207,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $207,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 1er juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale des Vieilles-Forges s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 17 avril 1974 \u2014 $2.000,000 \u2014 construction d'une école polyvalente à Ste-Geneviève-de-Batiscan.The Vieilles-Forges Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of thi« issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $207,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 1, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $207,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Vieilles-Forges Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after July 1, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: April 17,1974 \u2014 $2,000,000 \u2014 construction of a Comprehensive School in Ste-Geneviève-de-Batiscan. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3713 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 5 juin 1974, Polyvalente du Cap-de-Ia-Madeleine, 501, rue des Érables, Cap-de-Ia-Madeleine, comté de Trois-Rivières, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Trois-Rivières (Comté de Trois-Rivières), ce 13 mai 1974.Le directeur-général, Robert Lemieux.Centre administratif, 3255, rue Foucher, Trois-Rivières, (Trois-Rivières), P.Q., Téléphone: 379-5121, code 819.57303-o Avis de correction Concernant les avis de demandes de soumissions qui ont paru dans la Gazette officielle du Québec, pour l'achat d'émissions d'obligations des corporations ci-après énu-mérées seulement, on voudra bien noter que dans le préambule desdits avis, l'inscription des taux d'intérêts minimums et maximums est remplacée par la suivante: « avec intérêt à un taux non inférieur à 9% ni supérieur à 10% payable semi-annuellement ».Gazette officielle du 4 mai 1974 Cité de Drummondville.81,500,000 Village de Saint-Emile.680,000 Cité de Sillery.375,000 Gazette officielle du 11 mai 1974 Com.Scol.Rég.District of Bedford.S 590,000 Com.Scol.Deux-Montagnes.110,000 Ville de Douville.414,000 Com.Scol.Rég.de La Péninsule.1,885,000 Cité de LaSalle.2,153,000 Ville de Montréal-Est.1,084,000 Munie, de Notre-Dame-des-Monts.250,000 Le Comité de financement municipal 57299-0 du ministère des Affaires municipales.Ventes pour taxes Municipalité du comté de Mégantic Avis public est par le présent donné par René Che-vrier, secrétaire-trésorier, que les terrains ci-dessous mentionnés seront vendus à l'enchère publique dans le Village d'Inverness, au lieu où le Conseil de Comté tient ses sessions, MERCREDI, le DOUZIÈME jour de JUIN, 1974, à DIX heures du matin, tel que fixé par règlement, à défaut de paiement des taxes auxquelles ils sont affectés et des frais encourus.Municipalité du Canton d'Inverness Une partie du lot No 162, du cadastre officiel du Canton d'Inverness, mesurant 50 pieds de largeur en Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Wednesday, June 5, 1974 at 8:00 o'clock p.m., at the Comprehensive School of Cap-de-la-Madeleine, 501 des Érables Street, Cap-de-la-Madeleine, County of Trois-Rivières, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Trois-Rivières (County of Trois-Rivières), May 13, 1974.Robert Lemieux, Director General.Administration Centre, 3255 Foucher Street, Trois-Rivières, (Trois-Rivières), P.Q., Telephone: 379-5121, code 819.57303 Notice of change In connection with the notices for the request for tenders published in the Québec Official Gazette lor the purchase of the following bond issues and only for the corporations hereafter listed, kindly note that in the preamble of the said notices, the clause pertaining to minimum and maximum rates is replaced as follows: \"with interest at a rate not less than 9% no more than 10%, payable semi-annually\".Official Gazette of May 4,1974 Drummondville (City).81,500,000 Saint-Émile (Village).680,000 Sillery (City).375,000 Official Gazette of May 11, 1974 District of Bedford Regional School Board.8 590,000 Deux-Montagnes School Board.110,000 Douville (Town of).414,000 La Péninsule Regional School Board.1,885,000 LaSalle (City).2,153,000 Montreal-East (Town of).1,084,000 Notre-Dame-des-Monts (Municipality).250,000 Municipal Financial Committee 57299-0 of Department of Municipal Affairs.Sales for taxes Municipality of the County of Mégantic Public notice is hereby given by René Chevrier, Secretary-Treasurer, that the lands hereunder mentioned will be sold at public auction, in the village of Inverness, at the place where the county council holds its sittings, on WEDNESDAY, the TWELFTH day of JUNE, 1974, at TEN o'clock, a.m.as enacted by a by-law, in default of payment of taxes due thereon and costs incurred.Municipality of the Township of Inverness A part of the lot No.162, of the official cadastre of the Township of Inverness, measuring 50 feet in width 3714 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO avant et en arrière par 100 pieds de profondeur, bornée en front au nord-ouest au lac Joseph, en arrière au sud-est au chemin servant à l'usage des chalets, d'un côté au nord-est à une partie du même lot, (No 100) appartenant à Émilien Brochu, et de l'autre côté au sud-ouest par une partie du même lot (No 102), appartenant à Adrien Langlois, avec un chalet dessus construit.Ce terrain est connu au plan privé de Émilien Brochu comme étant le lot No 101.Avec un droit de passage dans le chemin servant aux emplacements de chalets et situé sur les lots Nos 160, 161 et 162, du susdit cadastre, et aussi sur la partie des lots Nos 234 et 233, du même cadastre, appartenant à Jean-Marie Pelletier, jusqu'au chemin public entre les lots Nos 232 et 233 dans le chemin tracé à cet effet.À la charge par l'acquéreur de contribuer à l'entretien du chemin servant à l'usage des chalets et de clore ledit terrain de tous les côtés touchant au terrain de Émilien Brochu, le tout tel que mentionné dans le titre consenti par ce dernier enregistré sous le No 113511.Connue comme appartenant à Dame Jean-Paul La-fontaine.Taxes dues: $56.56.Municipalité de Leeds Tous droits et prétentions appartenant au vendeur sur un terrain mesurant deux acres de largeur sur cinq acres de longueur le tout plus ou moins, connu et désigné comme faisant partie de la moitié sud-est du lot No 17-B du troisième rang du cadastre officiel du Canton de Leeds, borné comme suit, savoir: sur la largeur nord-est et sur la longueur nord-ouest par le terrain d'Aldéric Gagné, sur la longueur sud-est par le lot No 18, dans le troisième rang et sur la largeur sud-ouest par le deuxième rang, circonstances et dépendances.Connus comme appartenant à Jean-Jacques Naud.Taxes dues: $30.04.Municipalité de Ste-Anastasie Une partie du lot No 10, du deuxième rang du Canton de Nelson, prise à même la demie nord-est de cedit lot, mesurant deux cent soixante-dix pieds de largeur sur une profondeur de 150 pieds, ce terrain étant situé à environ 430 pieds du chemin et à 150 pieds de la ligne de division entre la demie nord-est du lot No 10 et la demie sud-ouest dudit lot No 10 et appartenant à Évariste Turcotte, bornée par la terre appartenant aujourd'hui i Paul Roby, le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Le tout avec un droit de passage pour se rendre au chemin public dans le chemin existant actuellement, ou à tout autre endroit déterminé par le propriétaire du fonds dominant (M.Paul Roby) et le moins onéreux pour la culture de la terre affectée de cette servitude.Ce droit de passage pouvant se pratiquer en tout temps de l'année et au moyen de tout véhicule pour l'utilité de ce terrain présentement vendu, le tout tel que réservé par le vendeur actuel dans un acte de vente enregistré sous le No 116292.Connue comme appartenant à Victor Ginzras.Taxes dues: $141.13.in front and at the rear by 100 feet in depth, bounded in front to the northwest by the lake Joseph, in rear to the southeast by the road used by the cottage owners, on one side to the northeast by a part of the same lot, (No.100) belonging to Émilien Brochu and on the other side to the southwest by a part of the same lot, (No.102) belonging to Adrien Langlois, with a cottage thereon erected.This land is known on a private plan of Émilien Brochu as being the lot No.101.With a right of way in the road used by the cottage owners and situated on the lots Nos.160, 161 and 162, of the said cadastre and also on the part of the lots Nos.234 and 233, of the same cadastre, belonging to Jean-Marie Pelletier, up to the public road between the lots Nos.232 and 233 in the road used as that effect.At the charge by the purchaser to contribute to the maintenance of the road used by the cottage owners and to fence the said land on all the sides adjoining the land of Émilien Brochu, the whole as mentioned in the title given by this latter and registered under the No.113511.Known as belonging to Dame Jean-Paul Lafontaine.Taxes due: $56.56.Municipality of Leeds All rights and pretentions belonging to the vendor on a land measuring two acres in width by five acres in lenght, the whole more or less, known and designated as forming part of the southeast half of the lot No.17-B, in the third range, of the official cadastre of the Township of Leeds, bounded as follows: on the northeast width and on the northwest length by the land of Albéric Gagné, on the southeast length by the lot No.18, in the third range and on the southwest width by the second range, circumstances and dependencies.Known as belonging to Jean-Jacques Naud.Taxes due: $30.04.Municipality of Ste-Anastasie A part of the lot No.10, in the second range of the Township of Nelson, taken from the northeast half of that said lot measuring two hundred and seventy feet in width by a depth of 150 feet, this land being situated at about 430 feet of the road and at 150 feet of the division line between the northeast half of the lot No.10 and the southwest half of the said lot No.10 and belonging to Évariste Turcotte, bounded by the farm belonging now to Paul Roby, the whole with buildings thereon erected, circumstances and dependencies.The whole with a right of way to reach the public road in the road actually existing, or at any place determined by the proprietor of the \"fonds dominant\" (M.Paul Roby) and at the least cost for the culture of the land affected by that servitude.This right of way to be used in any time of the year and with all kind of véhicule for the utility of the land presently sold, the whole as reserved by the actual vendor in a deed of sale registered under the No.116292.Known as belonging to Victor Gingras.Taxes due: $141.13. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3715 Municipalité de St-Joseph de Coleraine Un morceau de terre de 104 acres, plus ou moins, étant le lot No 22, dans le rang « A », Canton de Coleraine, sans bâtisse.Connu comme appartenant à J.Roger Beauchemin.Taxes dues: $179.09.a) Le lot de terre connu et désigné sous le No 2, de la subdivision du lot originaire No 3 du lot originaire Bloc « B » (Bloc 3-2) au cadastre officiel du Canton de Coleraine.6) Le lot de terre connu et désigné sous le No 1, de la subdivision du lot numéro un du lot original Bloc-B (Bloc B-l-1) au cadastre officiel dudit Canton de Coleraine.Avec les bâtisses, s'il y en a, selon les droits de l'acquéreur.Connus comme ayant déjà appartenus à la Coleraine Asbestos et acquise par Martinien Lacombe.Taxes dues : $1,534.88.Municipalité de Thetford Sud La moitié sud-est du lot No 9, rang « A » du cadastre officiel du Canton de Thetford.(Concession par billet de location du Ministère des Terres et Forêts à Siméon Acteau le 6 février, 1920) Connue comme appartenant à Léo Acteau.laxes dues: $247.93.Une partie du lot No 26-A, du septième rang du cadastre officiel du Canton de Thetford, de 50 pieds de largeur sur 100 pieds de profondeur, bornée en avant par le chemin public du septième rang, en arrière par une partie du même lot appartenant à Alphonse Roberge, d'un côté par le terrain de Stanislas Gilbert et de l'autre côté par une rue.Sous la réserve des mines et droits de mines en faveur de qui de droit.Avec bâtisses et dépendances.Connue comme appartenant à Robert Machel alias Mitchell.Taxes dues: 8388.57.Municipalité d'Halifax-Nord 1° Une terre contenant 140 arpents en superficie, plus ou moins, connue au cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax, comme étant la partie nord-ouest du lot No 1023, bornée au nord-est au,cordon entre les rangs cinq et six, au sud-ouest au cordon entre les rangs quatre et cinq, d'un côté au nord-ouest au lot No 1024 et de l'autre côté au sud-est à la partie sud-est du lot No 1023 appartenant à Joseph Vaillan-court ou ses représentants, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.2° Une autre terre contenant soixante-sept acres en superficie, plus ou moins, connue au cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax comme étant le lot No 998, sans bâtisse dessus.Sujette à une servitude de passage en faveur de la Cie d'Électricité Shawinigan, selon le titre s'y rapportent.Le lot No 998 est sujet à un bail en faveur de Shell Québec Limitée, selon acte enregistré sous le No 111484.Municipality of St-Joseph de Coleraine A piece of land of 104 acres, more or less, being the lot No.22, in the range \"A\", Township of Coleraine, without building.Known as belonging to J.Roger Beauchemin.Taxes due: 8179.09.a) The lot of land known and designated under the No.2, of the subdivision of the original lot No.3 of the original lot Bloc \"B\" (Bloc 3-2) of the official cadastre of the Township of Coleraine.b) The lot of land known and designated as No.1, of the subdivision of the lot No.1 of the original lot Bloc-B (Bloc B-l-1) of the official cadastre of the said Township of Coleraine.With the buildings, if there is any, according to the rights of the purchaser.Known as having formerly belonged to Coleraine Asbestos and purchaser by Martinien Lacombe.Taxes due: $1,534.88.Municipality of Thetford South The southeast half of the lot No.9, range \"A\" of the official cadastre of the Township of Thetford.(Concession par billet de location du Ministère des Terres et Forêts à Siméon Acteau, le 6 février 1920).Known as belonging to Léo Acteau.Taxes due: $247.93.A part of the lot No.26-A, of the seventh range of the official cadastre of the Township of Thetford, having 50 feet in width by 100 feet in depth, bounded in front by the public road of the seventh range, in rear by a part of the same lot belonging to Alphonse Roberge, on one side by the land of Stanislas Gilbert and on the other side by a street.Under the reserve of the mines and mining rights in favor of whom they may belong.With buildings and dependencies.Known as belonging to Robert Machel alias Mitchell.Taxes due: $388.57.Municipality of Halifax North 1.A farm containing 140 arpents in superficies, more or less, known on the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax, as being the northwest part of the lot No.1023, bounded to the northeast by the division line between ranges 5 and 6, to the southwest by the division line between ranges 4 and 5, on one side to the northwest by the lot No.1024 and on the other side to the southeast by the southeast part of the lot No.1023 belonging to Joseph Vaillancourt, or representatives, with the buildings thereon erected, circumstances and dependencies.2.Another farm containing 67 acres in superficies, more or less, known on the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax, as being the lot No.998, without building.Subject to a servitude of passage in favor of The Shawinigan Water and Power Co., according their title.The lot No.998 is subject to a lease in favor of Shell Québec Ltée, as per deed registered under the No.111484. 3716 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Connues comme appartenant à Roger Simoneau.Taxes dues: $131.40 Une terre contenant 149 acres en superficie, plus ou moins, connue au cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax, comme étant les lots Nos 832 (59 ac), 833 (44 a.) et la moitié sud-ouest du lot No 834 (46 ac), cette dernière étant bornée au nord-est à la moitié nord-est du même lot, appartenent à Gérard Labonté, au sud-ouest au cordon du rang, au sud-est au lot No 833 et au nord-ouest au lot No 835.Avec les bâtisses érigées sur cette terre.François Gingras réserve tout le bois mou commercial sur la terre vendue, pour une période de deux ans à compter du 20 mars, 1972.Ces droits de coupe ne s'appliqueront pas à la partie basse du lot 834 le long du terrain de Gérard Labonté.Le lot No 832 est sujet à la servitude de prise d'eau dans une source en faveur d'une partie du lot No 795, du même cadastre, avec droits accessoires, tel que le tout est établi dans la vente enregistrée sous le No 120614.La terre vendue est sujette à un bail en faveur de Shell Québec Limitée, selon le titre s'y rapportant enregistré sous le No 111273.Sauf et à distraire du lot No 832, la lisière de terrain vendue au Ministère de la Voirie, selon acte enregistré sous le No 101197.La terre ci-dessus décrite est sujette à une servitude en faveur de la Cie de Téléphone Bell du Canada, selon titre enregistré sous le No 103775.Le lot No 833 est sujet à une servitude de fossé en faveur de la Voirie, selon titre enregistré sous le No 101459.Connue comme appartenant à Jean-Paul Le Bourhis.Taxes dues: $113.74.Les lots Nos 783, 784 et 785, du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax, contenant environ 160 acres en superficie, avec maison et autres bâtisses dessus construites.Sauf et à distraire la partie nord-est desdits lots Nos 783, 784 et 785, mesurant sept arpents de largeur par toute la profondevr comprise entre la rivière et le cordon entre les rangs 10 et 11, vendue à Jean-Charles et Robert Beaudoin, par acte enregistré sous le No 123459.La partie sud-ouest dudit lot No 785 étant sujette au droit de puiser de l'eau dans une source y située et tel que mentionné dans le titre enregistré sous le No 123459.Connues comme appartenant à Rosaire Gosselin.Taxes dues: $91.45.Les lots Nos 267, 268 et 269, du cadastre officiel de la Paroisse de St-Ferdinand, Canton d'Halifax.Sujets à une servitude de passage en faveur de The Shawinigan Water & Power Co., selon les titres s'y rapportant.Sauf et à distraire la partie nord-est desdits lots Nos 267, 268 et 269 vendue à Emile Marcoux par acte enregistré sous le No 122089.Sauf et à distraire également une partie dudit lot No 267 vendue à Michel Marcoux, avec un droit de Known as belonging to Roger Simoneau.Taxes due: $131.40.A farm containing 149 acres in superficies, more or less, known on the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax, as being the lots Nos.832 (59 ac), 833 (44 ac.) and the southwest half of lot No.834 (46 ac), this later being bounded to the northeast by the northeast half of the same lot, belonging to Gérard Labonté, to the southwest by the division line of the range, to the southeast by the lot No.833 and to the northwest by the lot No.835.With the buildings erected on that farm.François Gingras reserves all commercial wood on the farm sold, for a period of 2 years from the 20th of March 1972.These rights of cut will not apply to the lower part of the lot No.834 along the land of Gérard Labonté.The lot No.832 is subject to a right of water in a spring in favor of a part of the lot No.795, of the same cadastre, with accessory rights, as the whole is related in the deed of sale registered under the No.120614.The farm sold is subject to a lease in favor of Shell Québec Limitée, as per deed registered under the No.11273.Save and except from the lot No.832, the piece of land sold the Ministère of la Voirie, as per deed registered under the No.101197.The farm above described is subject to a servitude in favor of Bell Canada, as per deed registered under the No.103775.The lot No.833 is subject to a servitude of ditch in favor of la Voirie, as per deed registered under the No.101459.Known as belonging to Jean-Paul Le Bourhis.Taxes due: $113.74.The lots Nos.783,784 and 785, of the official cadastre of the Parish of Ste-Sophie, Township of Halifax, containing about 160 acres in superficies, with a house and other buildings thereon erected.Save and except the northeast part of the said lots Nos.783, 784 and 785, measuring 7 arpents in width by all the depth included between the river and the division line between ranges 10 and 11, sold to Jean-Charles and Robert Beaudoin, by deed registered under the No.123459.The southwest part of the said lot No.785 is subject to a right of water in a spring thereon situated the whole as mentioned in the title registered under the No.123459.Known as belonging to Rosaire Gosselin.Taxes due: $91.45.The lots Nos.267, 268 and 269 of the official cadastre of the Parish of St.Ferdinand, Township of Halifax.Subject to a right of way in favor of The Shawinigan Water and Power Co., according to their title.Save and except the northeast part of the said lots Nos.267, 268 and 269 sold to Emile Marcoux by deed registered under the No.122089.Also save and except a part of the said lot No.267 sold to Michel Marcoux, with a right of way on a part GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3717 passage faisant partie du même lot No 267, par acte enregistré sous le No 124350.Connus comme appartenant à Maurice Rousseau.Taxes dues: $57.45.1° Une partie du lot No 1075, du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax, mesurant 1025 pieds de profondeur par douze arpents et demi de largeur, étant toute la largeur du lot 1075, bornée au nord-est par le cordon entre le 4e et le 5e rangs dudit Canton d'Halifax, au sud-ouest par le résidu dudit lot 1075 demeurant la propriété du vendeur, au sud-est au lot 1076 et au nord-ouest au lot 1074, sans bâtisse.2° Le lot No 1076, du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax; sauf et à distraire la partie vendue à la Corporation Municipale d'Halifax-Nord, par l'acte enregistré sous le No 105480; sauf et à distraire la partie vendue à Hervé Faucher par l'acte enregistré sous le No 111323 et la partie vendue au Ministère de la Voirie, par acte enregistré sous le No 118556.3° Le lot No 1077, du cadastre officiel de la Paroisse de Ste-Sophie, Canton d'Halifax; sauf et à distraire la partie sud-ouest du lot, située du côté sud-est de la route conduisant au Village de Ste-Sophie, ce morceau de terrain mesurant environ 14 arpents de profondeur par toute la largeur du lot comprise entre la route et le lot No 1078.Sauf et à distraire la partie centre dudit lot No 1077, mesurant environ 8 arpents de largeur dans le sens de la route, par environ deux arpents et demi de profondeur, vendue à Hervé Faucher par acte enregistré sous le No 111323.Sauf et à distraire la partie dudit lot No 1077 vendue à Conrad Boutin par acte enregistré sous le No 113836.Connus comme appartenant à Réal Beaudoin.Taxes dues: $64.44.Inverness, le 25 avril, 1974.Le secrétaire-trésorier, 57160-19-2-o René Chevrier.Ville de Longueuil Avis est par la présente donné, que le Conseil Municipal, par une résolution en date du 6ième jour de mai 1974, a ordonné au soussigné, conformément à la loi des cités et villes, de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Ville de Longueuil, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public, dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de Longueuil, 100 rue St-Charles Ouest, le DIX-NEUVIÈME jour de JUIN 1974 à DIX heures de l'avant-midi, heure avancée de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente, les immeubles sur lesquels les taxes municipales de l'année 1973 et des années antérieures, ainsi que les intérêts et frais, auront été payées avant le moment de la vente.Permission, a été accordée par la Commission Municipale de Québec, pour autoriser une enumeration abrégée des numéros cadastraux.of the said lot No.267, by deed registered under the No.124350.Known as belonging to Maurice Rousseau.Taxes due: $57.45.1.A part of the lot No.1075, of the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax, measuring 1025 feet in depth by 12 arpents and a half in width, being the whole width of the lot No.1075, bounded to the northeast by the division line between ranges 4 and 5 of the said Township of Halifax, to the southwest by the residue of the said lot 1075 remaining the property of the vendor, to the southeast by the lot 1076 and to the northwest by the lot No.1074, without building.2.The lot No.1076, of the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax; save and except the part sold to the Municipal Corporation of Halifax-North, by the deed registered under the No.105480; save and except the part sold to Hervé Faucher by the deed registered under the No.111323 and the part sold to la Voirie by the deed registered under the No.118556.3.The lot No.1077, of the official cadastre of the Parish of Ste.Sophie, Township of Halifax; save and except the southwest part of the lot, situated on the southeast side of the road leading to the village of Ste.Sophie, that piece of land measuring about 14 arpents in depth by the whole width of the lot included between the road and the lot No.1078.Save and except the center part of the said lot No.1077, measuring about 8 arpents in width along the road, by about two arpents and a half in depth, sold to Hervé Faucher by deed registered under the No.111323.Save and except the part of the said lot No.1077 sold to Conrad Boutin by deed registered under the No.113836.Known as belonging to Real Beaudoin.Taxes due: $64.44.Inverness, April 25, 1974.René Chevrier, 57160-19-2-o Secretary-Treasurer.City of Longueuil Public notice is hereby given, that the City Council by a resolution dated May 6th, 1974, has ordered the undersigned, persuant to the Cities and Towns act: to sell the immovables hereinunder described for nonpayment of taxation arrears owing to the Corporation of the City of Longueuil, with interest and cost, and that consequently the said immovables shall be sold by public auction in the Council room at the City Hall of Longueuil.100 west, St-Charles street, City of Longueuil on the NINETEENTH day of JUNE 1974, at TEN o'clock in the forenoon eastern daily saving time.However, there shall be excluded from the sale, the immovables on which municipal taxes, for the year 1973 and previous year with interest and cost, shall have been prior to the sale.The Québec Municipal Commission has authorized the City of Longueuil, an abridged form of cadastral numbers. 3718 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO La vente des immeubles décrits dans la troisième partie sera définitive et sans droit de retrait en vertu du paragraphe « B » de l'article 4 des lettres patentes créant la Ville de Longueuil.Première partie: Immeubles sujets au droit de retrait d'un an du cadastre officiel de la Paroisse St-Antoine de Longueuil dans les limites de la Ville de Longueuil.Deuxième partie: Immeubles sujets au droit de retrait d'un an du cadastre officiel du Village de Longueuil Inc.dans les limites de la Ville de Longueuil.Troisième partie: Immeubles non sujets au droit de retrait d'un an du cadastre officiel de la Paroisse St-Antoine de Longueuil, dans les limites de la Ville de Longueuil.Us seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis de la Ville de Longueuil, et à toutes les servitudes actives ou passives apparentes ou accultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.The sale of immovables described in third section shall be final without right of redemption, in virtue of paragraph \"B\" of section 4 of the letters patent creating the City of Longueuil.First Section: Immovables subject to the one-year right of redemption, of official cadastre of the Parish of St-Antoine of Longueuil, within the limits of the City of Longueuil.Second Section : Immovables subject to the one-year right of redemption, of official cadastre of the Village of Longueuil Inc., within the limits of the City of Longueuil.Third Section: Immovables not subject to the one-year right of redemption, of official cadastre of the Parish of St-Antoine of Longueuil, within the limits of the City of Longueuil.They shall be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if any, subject to all the acquired rights of the City of Longueuil, and any servitudes both active and passive, apparent or unap-parent which may affect them.The purchase price of said immovables shall be payable immediately.Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes Sale of immovables for the non-payment of taxes Première partie First Section Immeubles sujets au droit de retrait d'un an Immovables subject to the one-year right of withdrawal (Les lots ci-après décrits sont du cadastre officiel de la paroisse St-Antoine de Longueuil dans les limites de la Ville de Longueuil) (The lots hereinafter described are from the official cadastre of the Parish of St-Antoine of Longueuil within the limits of the City of Longueuil) Nom et adresse Description de l'immeuble Folio Name and address Description of immovable 2325-0266 2317-0507 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal, Que.M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal, Que.15-2 Une partie du lot 15-13.contenant une superficie de 21,339 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit, à savoir: au nord par les lots 15-22, 15-21, au sud, par les lots 15-9, 15-10 et une partie du lot 15-11, & l'ouest par le résidu dudit lot 15-13, et à l'est, par le lot 15-2.A part of lot 15-13, having an area of 21,339 square feet, English measure and more or less, and bounded as follows to wit: on the north, by lots 15-22, 15-21, on the south, by lots 15-9, 15-10 and a part of lot 15-11, on the west by the residue of said lot 15-13, and on the east by lot 16-2.2325-0275 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal 107, Que.Une partie du lot 16-53, contenant une superficie de 49,913 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord, par le résidu dudit lot 16-53, au sud par le lot 15-2, à l'ouest par les lots 15-32, 15-31, 15-30, 15-29, 15-28 et une partie du lot 16-27 à l'est par une partie du lot 15-60.A part of lot 15-53, having an area of 49,913 square feet.English measure and more or less, and bounded as follows, to wit: on the north by the residue of said lot 15-53, on the south by lot 15-2, on the west, by lots 15-32, 15-31.15-30, 15-29, 15-28 and a part of lot 15-27 and on the east by a part of lot 15-60.2320-0590 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal 107, Que.2320-0600 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal 107, Que.2320-0610 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, suite 200, Montréal 107, Que.2330-0090 M.Théodore Chodos, 18 Chemin Belsize, Montréal 254, Que.16-56 15-57 15-58 17-112-1 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3719 Folio Nom et adresse Description de l'immeuble Name and addrese Description of immovable 2330-0080 Sabal Holdings Corp.a/s-c/o M.Abe Chodos C.A., 4141 Sherbrooke ouest, 17-112-2 Montréal 216, Que.1234-1344 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 11,200 square feet, 11,200 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par les lots 21-88 et 27-38A, et wit: on the north by lot3 21-88 and 27-38A.and by a part of par une partie du lot originaire 27, au sud par une rue 21-102, original lot 27, on the south by a street 21-102, on the east by à l'est par une rue 21-86, et à l'ouest par une autre rue 21-96.a street 21-86, and on the west by another street 21-96.1234-1372 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 26, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 11,250 square feet, 11,260 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par le lot 21-73 et par une partie wit: on the north by lot 21-73 and by part of original lot 27, on du lot originaire 27 au sud par une rue 21-102, à l'est par une the south by a street 21-102, on the east by a street 21-72, and rue 21-72, et à l'ouest par une autre rue 21-86.on the west by another street 21-86.1234-1392 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 25.Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 33,600 square feet, 33,600 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit savoir: au nord par la ligne limitative des terres wit: on the north by the separative line of lots of lands 21 and 21 et 27 et par une partie du lot 26-1, au sud par une rue 21-102, 27, and by a part of lot 26-1, on the south by a Street 21-102.à l'est par une rue 21-63, et à l'ouest par une autre rue 21-72.and on the west by another street 21-72, and on the east by a street 21-53.1234-1410 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 48,000 square feet.48,000 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative des terres wit: on the north by the separative line of lots of lands 21 and 21 et 25, au sud par une rue 21-102, à l'est par une rue 21-30 25, on the south by a street 21-102, on the east by a street et à l'ouest par une autre rue 21-53.21-30 and on the west by another street 21-53.1234-1440 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 21.contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 16,800 square feet, 16,800 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative des terres wit: on the north by the separative line of lots of lands 21 and 21 et 25, au sud par une rue 21-6, à l'ouest par une autre rue 25, on the south by a Street 21-6, on the east by the separative 21-30, et à l'est par la ligna limitative des terres 21 et 17.line of lots of lands 21 and 17.On the west by another street 21-30.1234-1442 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 2O0, Montréal 26, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 27,000 square feet, 27,000 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-6, au sud par une wit: on the north by a street 21-6, on the south by a street rue 21-20, & l'ouest par une autre rue 21-30, et à l'est par la 21-20, on the west by another street 21-30, and on the east by ligne limitative des terres 17 et 21.the separative line of lots of lands 17 and 21.1234-1444 M.Ben Lechter.2015 Drummond, chambre 200.Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 20,400 square feet, 20,400 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-20, à l'ouest par wit: on the north by a street 21-20, on the west by a street une rue 21-30, à l'est par la ligne limitative des terres 17 et 21, 21-30, on the east by the separative line of lots of lands 17 and et au sud par la ligne limitative de la terre 21.21, and the south by the separative line of land 21.1234-1412 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 25.Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21.having an area of 22,400 square feet.22,400 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-102, au sud par la wit: on the north by a street 21-102, on the south by the ligne limitative de la terre 21, à l'est par une rue 21-30, et à separative line of land 21, on the east by a street 21-30, and l'ouest par une autre rue 21-113.on the west by another street 21-113.1234-1394 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 26, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 25,500 square feet, 25,500 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-102, à l'est par une wit: on the north by a street 21-102, on the east by a street rue 21-113, à l'ouest par une autre rue 21-127, et au sud par la 21-113, on the west by another street 21-127, and on the south ligne limitative de la terre 21.by the separative line of land 21.1234-1374 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 26, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot21, having an area of 31,500 square feet, 31,500 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to 3720_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 197j, Vol.106, No.20___ comme suit, savoir: au nord par une rue 21-102, à l'ouest p»r wit: on the north by a street 21-102, on the ^*^y ^'reet une autre rue 21-144, et au sud par laligne limitative de la terre 21-144.on the east by another Street .21-1.!/.ana on me soutn 21, à l'est par une rue 21-127.by the separative line of land £1.1234-1346 M.Ben Lechter, 2015 Drummond.chambre 200, Montréal 25.Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 36^600'square feet 36,600 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more of 'ess.and bounded as '°\"owsj » comme suit, savoir: au nord par une rue 21-102, à l'ouest par wit: on the north by a street 21-102, on the \"e,8t\u201e^y* une rue 21-164, à l'est par une autre rue 21-144, et au sud par 21-164, on the east by another street 21-144, and on the south la ligne limitative de la terre 21 et par une partie du lot 21-187.by the separative line of land 21 and by a part oi lot, 1234-1322 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200.Montréal 25.Que.Une partie du lot originaire 21.contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 42,400 square feet.42,400 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as loilows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-102, et par les lots wit: on the north by a street 21-102 and by lots -il-17.i and 21-172 et 21-173.au sud par une rue 21-187, à l'est par une rue 21-173.on the south by a Street 21-187.on the east by a street 21-164 et par le lot 21-173, à l'ouest par une autre rue 21-186.21-164 and by lot 21-173, on the west by another street 21-186.1234-1324 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 49,500 square feet, 49,600 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as loilows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-187, au sud par une wit: on the north by a street 21-187, on the south by another autre partie du lot originaire 21, à l'ouest par une rue 21-214 et part of said original lot 21, on the west by a street 21-214, and à l'est par la ligne limitative de la terre 21.on the east by the separative line of land 21.1234-1326 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25.Que.Une partie du lot originaire 21.contenant une superficie de A part of original lot 21.having an area of 105,600 square 105,600 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bor- feet, English measure and more or less, and bounded as follows, née comme suit, savoir: au nord par une rue 21-187, à l'ouest to wit: on the north by a street 21-187, on the west by a street par une rue 21-265, à l'est par une autre rue 21-214 et au sud 21-265, on the east by another street 21-214 and on the south par une autre partie du lot originaire 21.by another part of original lot 21.1234-1328 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.Une partie du lot originaire 21, contenant une superficie de A part of original lot 21, having an area of 96,800 square feet, 96,800 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or less, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 21-187, à l'ouest par wit: on the north by a street 21-187, on the west by a street une rue 21-314, à l'est par une autre rue 21-265, et au sud par 21-314, on the east by another street 21-265 and on the south une autre partie du lot originaire 21.A distraire de ces tenants by another part of said original lot 21.To withdraw from et aboutissants les lots 21-293 et 21-294.those boundaries and abuttals lots 21-293 and 21-294.1234-1318 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200.Montréal, Que.Une partie du lot originaire 21, de figure irrégulière, conte- A part of original lot 21, of irregular shape having an area of nant une superficie de 63,250 pieds carrés, mesure anglaise 63,250 square feet, English measure and more or less, and boun- et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par ded as follows, to wit: on ihe.north by a street 21-352, on the une rue 21-352, à l'ouest par le lot 21-346 et de la ligne Hmi- west by lot 21-346 and the separative line of lots of lands 21 tative des terres 21 et 23 à l'est par une rue 21-314 et au sud and 23, on the east by a street 21-314 and on the south by par une autre partie du lot originaire 21.another part of said original lot 21.1234-1300 M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.Une partie du lot originaire 27, contenant une superficie de A part of original lot 27, having an area of 10,800 square 10,800 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée feet English measure and more or less, and bounded as follows, comme suit, savoir: au nord par le Chemin du Lac, au sud par to wit: on the north by Chemin du Lac, on the south by a part une partie du lot 27-40A, les lots 27-41A, 27-42A, 27-43A, of lot 27-40A, 27-41A, 27-42A, 27-43A, 27-44A and 27-45A, on 27-44A et 27-45A, à l'est par le lot 27-52A, à l'ouest par une the east by lot 27-52A, on the west by a street 27-47A.autre rue 27-47A.1234-1340 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.,.7j?S p.a?ie du,lot originaire 27, contenant une superficie de A part of original lot 27, having an area of 15,725 square 16,725 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée feet English measure and more or less, and bounded as follows, comme suit, savoir: au nord par le Chemin du Lac et par le lot to wit: on the north by Chemin du Lac and by lot 27-35.on 27-35, au sud par les lots 21-87, 21-88 et par une partie du lot the south by lots 21-87, 21-88 and by a part of original lot 21 originaire 21 et par le lot 27-38A, à 1 est par une rue 27-23A, and by lot 27-38A, on the east by a street 27-23A, on the west 27-35A 9 et Par les lot8 27\"31A- 27-34A et by a street 27-39A and by lots 27-31A, 27-34A and 27-35A.1234-1370 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.12 OOO nipHtie™ii?t^IiBinaire ?7-' co!lte,nant une superficie de A part of original lot 27, having an area of 12,000 square I™^°,P.ï \u2022 ' 6SUre angla,18«P,us °u ™>»>.et bornée feet.English measure and more or less, and bounded aVfollows SEPS?*»' ?v\"'ï a\" n0reLPfoRdeoJ\"!oC'58 94-1253.94-1254.94-1249.94-1262, 94-1261, 94-1266, 94-1256.au'2&2 \u201e.m; ?t 2 qVws q^o^'o?'^?4\"1256' 9.4-'255' OD thl 80uthea8t by I\"* 05-228.95-227, 96-351.on the south: n»r ,™ S .i , 9^ ' d .» i96\"351' \"u Pfty^ «e»t by part of original lot 96 and on the west by Chambly par une partie du lot originaire 96 et à l'ouest par le Chemin Road.* Chambly. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3727 Folio Nom et adresse Name and addrett Description de l'immeuble Deicription of immutable 1001-2451 Mercury Realties Inc., 2015 Drummond, chambre 200.Montreal 107.Que____ Le lot 94-238.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 94-238, to withdraw however the part used as a street.1421-0035 M.Maurice Jasmin, 36 Jules-Roche est, Longueuil, Que.94-245, 246-1 1420-0110 M.Marc Robidas, 261 Boul.Langlois.St-Jean, Que.94-301, 302, 303 1419-0067 M.Yvano Martel, 67 Briand, Longueuil, Que.94-338,339 1419-0073 M.Yvano Martel, 73 Briand, Longueuil, Que.94-340,341 1418-0082 Fidelity Developments Inc., adresse inconnue.94-373,374 1418-0126 M.Jose-Carlos Simoes, CP.693, Gait, Ont.94-383,384 1423-0085 Omega Investments Limited, 455 Michel-Jasmin, Dorval 740, Que.Une partie du lot 94-1254, de forme irrégulière, contenant A part of lot 94-1254, of irregular shape, having an area of une superficie de 4,050 pieds carrés, mesure anglaise, et plus 4,060 square feet.English measure and more or lees, and ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par ute bounded as follows, to wit: on the north, by a part of lot 94-partie du lot 94-1253.à l'ouest, par une autre partie du lot 1253, on the west by another part of lot 94-1254.on the south-94-1254, au sud-ouest et sud-est par d'autres parties du lot west and southeast by other parts of lot 94-1249.94-1249.1426-0123 Omega Investments Ltd., 465 Michel-Jasmin, Dorval, 740, Que.94-1295 1422-0124 Omega Investments Ltd., 456 Michel-Jasmin, Dorval 740, Que.94-1296 1708-0130 M.Florian Parent, a/s-c/o M.Roland Harvey.450 Sherbrooke est.suite 200C.97-38 Montréal, Que.1716-0314 M.Maurice Lévesque, 314 Proulx.Longueuil, Que.97-200 1312-2690 M.Claude Malo, 8295 Drolet, Montréal 351, Que.97-319 1722-2800 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, Que.Une partie du lot originaire 98, de forme irrégulière, conte- A part of original lot 98, of irregular shape, having an area nant une superficie de 26,630 pieds carrés, mesure anglaise, of 26,530 square feet, English measure and more or less, and et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord-est bounded as follows, to wit: on the northeast and east by a et à l'est par une rue 98-1782, au nord-ouest par une rue 98- street 98-1782, on the northwest by a street 98-1776.on the 1778, au sud par une autre rue 98-1780, et à l'ouest par les south by another street 98-1780, and on the west by lots 98-lots 98-1843 et 98-1842.1843 and 98-1842.1722-2820 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Ville Mont-Royal.Que.Un emplacement, composé d'une partie du lot originaire 93, A site, composed of a part of original lot 98, aod a part of et une partie du lot 98-1890, contenant une superficie de lot 98-1890.having an area of 64.292 square feet.English 64,292 pieds carrés, mesure anglaise, et plue ou moins, et measure and more or less, and bounded as follows, to wit: bornée comme suit, savoir: au nord-est et nord-ouest par une on the northeast and northwest, by a street 98-1780, on the rue 98-1780, à l'est par une rue 98-1783, au sud-est par le lot east by a street 98-1783.on the southeast by lot 98-1891, on 98-1891, au sud-ouest par le lot 98-1969.à l'ouest par les lots the west by lots 98-1947.98-1835 and by a street 98-1779.98-1947, 98-1835 et par une rue 98-1779.On southwest by lot 98-1959.1737-0223 François Construction Ltée, 150 Boul, Desormeaux.Longueuil, Que.98-1831 1736-0242 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal.98-1835 Que.1736-0236 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1836 Que.1736-0230 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1837 Que.1736-0224 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal.98-1838 Que.1736-0218 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1839 Que.1736-0212 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Ville Mont-Royal.98-1840 Que.1736-0206 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1841 Que.1736-0200 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal.98-1842 Que.1728-0246 François Construction Ltée, 160 Boul.Desormeaux.Longueuil, Que.98-1847 1728-0240 François Construction Ltée, 160 Boul.Desormeaux, Longueuil, Que.98-1848 1728-0234 François Construction Ltée.160 Boul.Desormeaux, Longueuil, Que.98-1849 1728-0228 François Construction Ltée, 160 Boul.Desormeaux, Longueuil, Que.98-1850 1722-2900 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1891 Que.1720-2800 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Ville Mont-Royal, 98-1894 1737-0217 François Construction Ltée.160 Boul.Desormeaux, Longueuil, Que.98-1945 1312-2870 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Ville Mont-Royal.98-1981 Que.1801-2977 M.Jules Lague, 102 Pierre-Davignon.Boucherville, Que.99-944 1840-2950 M.Robert Grenier.2950 Martigny, Longueuil, Que.99-1099 3728 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom et adresse Description de l'immeuble Mime and addreti Description of immovable 1001-3459 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305.Que.Une partie du lot originaire 108, contenant une superficie A part of original lot 108, having an area of 422.259 square de 422,259 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins.feet, English measure and more or leas, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord par la ligne limitatire follows, to wit: on the north by the limiting line of lots ol des terres 108 et 107, au sud la ligne limitative des terres 108 lands 108 and 107, on the south by the limiting line of lots et 109, à l'ouest par le Chemin Chambly.et à l'est par les lots of lands 108 and 109, on the west by Chambly Road, and on 108-30, 108-29, 108-28, 108-27, 108-26 et 108-25.the east by lots 108-30, 108-29, 108-28, 108-27, 108-26 and 108-25.1922-1190 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, «uite 2A, Montréal 305, Que.Une partie du lot originaire 108.contenant une superficie A part of original lot 108.having an area of 36.800 square de 36,800 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, «t feet, English measure and more or leas, and bounded as fol-bornée comme suit, savoir: au nord-ouest par une rue 108-19.lows, to wit: on the northwest by a street 108-19.on the east à l'est par le lot 108-24, et au sud par la ligne limitative des by lot 108-24 and on the south by the limiting line of lots of terres 108 et 109.lands 108 and 109.1915-3521 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Montréal 306.Que.108-36 1918-0190 Rock Enterprises Ltd.2300 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305.Que.108-40 1934-0494 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Montréal 305.Que.108-94 1311-3509 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.108-182 1001-3537 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305.Que.Une partie du lot originaire 109.contenant une superficie A part of original lot 109, having an area of 294,258 square de 294.258 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, feet, English measure and more or leas, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord, par une autre partie follows, to wit: on the north by another part of origina] lot du lot originaire 109, et par le lot 109-112.au sud par la rue 109 and by lot 109-112.on the south by Cuvillier Street and Cuvillier et par le lot 109-2, à l'ouest, par le lot 109-2 et parle by lot 109-2, on the west, by lot 109-2 and by Chambly Chemin Chambly, et à l'est par une partie du lot 109-38, et Road, and on the east by a part of lot 109-38, and by lota par les lots 109-37.109-36, 109-35 et 109-111.109-37, 109-36.109-35 and 109-111.1311-3537 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.a) Une partie du lot originaire 109.de forme irrégulière.(a) A part or original lot 109.of irregular shape, bounded as bornée au nord par les lots 108-178 et 108-186 et par une rue follows, to wit: on the north, by lots 108-178 and 108-186 and 109-22.à l'est par une rue 109-23, au sud par le lot 109-110 et by a street 109-22, on the east, by a street 109-23.on the south par une rue 109-21 et à l'ouest par le lot 109-110et par une rue by lot 109-110 and by a street 109-21, and on the west by lot 109-20.109-110 and by a street 109-20.b) Une partie du lot originaire 109, bornée au nord par les (6) A part of original lot 109, bounded on the north by lota lots 108-204 et 108-209, à l'ouest et au sud par une rue 109-22 108-204 and 108-209, on the west and south by a street 109-22, et à l'est par une autre rue 109-23.and on the east by another street 109-23.La superficie totale de ces deux parties de lot 109 est de The total area of those parts of original lot 109, on sale are l'ordre de 123,292 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou 123,292, square feet, from the English measure and more or moins.less.1922-1150 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.Une partie du lot originaire 109, contenant une superficie A part of original lot 109, having an area of 215,748 square de 215,748 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, feet.English maesure and more or less, and bounded as fol- et bornée comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative lows, to wit: on the north by the limiting line of lots of lands des terres 108 et 109, au sud par la ligne limitative des terres 108 and 109, on the south by the limiting line of lots of lands 109 et 110.au nord-oueat par une rue 109-24 et au sud-ouest 109 and 110, on the northwest by a street 109-24 and on the par une autre rue 109-26.southwest by another street 109-26.3819-0521 Rock Enterprises Ltd.2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.Une autre partie du lot originaire 109, contenant une super- A part of original lot 109.having an area of 15.400 square ficie de 15.400 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins.feet, English measure and more or less, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord par le lot 108-203.au follows, to wit: on the north by lot 108-203, on the south by sud pgr le lot 109-135.à l'est par le lot 109-134 et à I'oues'.lot 109-135.on the east by lot 109-134 and on the west by a par une rue 109-23.street 109-23.1916-3581 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Montréal 305, Que.109-45.1311-3575 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Montréal 306, Que.109-110.3807-1181 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.a Vf?J!%Hi° du lot or'Kinaire u°.contenant une superficie A part of original lot 110, having an area of 74,743.square de 74,743 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, feet, English measure and more or less, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative follows, on the north by the limiting line of lots of lands ,.3 ftnuLi\"! SV °' au 8ud par \"\"\".TH?1,0_93 a ' \u2022* P\" 109 \"\"d 110- on tl» aouth by a street 110-93 on the east by lot 110-100.et à I ouest par une rue 110-92.lot 110-100, and on the west by a street 110-92.?f23_2fSi 500!1 Enterprises Ltd., 3360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305.Que.110-283.iiii\" SHE 5 ¦ enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.110-331.,?.i,in,\u201e !., Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.110-332, 333.1001-3717 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 306, Que.Une partie du lot originaire 111, de forme triangulaire.A part of original lot 111, of triangular shape, havins an contenant une superficie de 64,698 pieds carrés, mesure an- area of 64.698 square feet, English measure, and more or less, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° SO 3729 Folio Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable glaise, et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord and bounded as follows, to wit: on the north by Vauquelin par le Boulevard Vauquelin, au sud, par les limites des Villes Blvd., on the south, by the limits of the Cities of Longueuil de Longueuil et St-Hubert, et à l'ouest par le Chemin Chambly.and St-Hubert, and on the west by Chambly Road.3822-3660 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.111-249.3812-1190 Rtock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A.Montréal 305, Que.111-291.3812-1200 Rock Enterprises Ltd., 2360 Chemin Lucerne, suite 2A, Montréal 305, Que.111-292.1000-3570 Mercury Realties Inc.a/s-c/o M.Ben Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Le lot originaire 114 contenant une superficie de 747,412 The original lot 114 having an area of 747,412 square feet, pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure, and more or less and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative des terres wit: on the north by the separative line of lots of lands 114 114 et 115, au sud par la ligne limitative des terres 113 et 114, and 115, on the south by the separative line of lots of lands à l'est par le Chemin Chambly, et à l'ouest, par la ligne ouest 113 and 114, on the east by Chemin Chambly and on the de ladite terre 114.west, by the line of said land 114.A distraire toutefois les parties expropriées.To withdraw however the expropriated parts.1000-3500 M.Ben Lechter, 2015 Drummond.chambre 200, Montréal 107.Que.Une partie du lot originaire 115, contenant une superficie A part of original lot 115.having an area of 746,951 square de 746,951 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, feet, English measure and more or less, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord par la ligne limitative follows, to wit: on the north by the separative line of lots of des terres 115 et 116, au sud par la ligne limitative des terres lands 115 and 116, on the south by the separative line of lots 116 et 114, à l'est par le Chemin Chambly, et à l'ouest, par la of lands 115 and 114, on the east by Chemin Chambly, and limite ouest de ladite terre 115.on the west by the west limit of said land 115.A distraire toutefois la partie expropriée et le lot 116-2.To withdraw however the expropriated part and lot 116-2.1000-3180 M.Ben Lechter.2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.Les lots 119-2 et 119-51, à distraire toutefois de ces lots, les Lots 119-2 and 119-51, to withdraw however from those parties expropriées, et la partie vendue pour former le lot lots, the expropriated parts, and the part sold to complete 119-2-1.lot 119-2-1.1691-3111 M.André Boulanger, adresse inconnue.120-117-25.1691-3123 M.Jean-Guy Salinesi, adresse inconnue.120-117-28.1000-3138 Restaurant Lapino Inc., 110 Desormeaux.Longueuil, Que.120-127.1677-1165 Mme / Mrs.Janine Hébert-Lagarde, 4169 St-Hubert.Montréal, Que.121-285, 201-472-2.473.1674-3098 M.Gérard Tremblay.3100 Duvivier.Longueuil.Que.121-290.1674-3108 M.Gérard Tremblay, 3100 Duvivier.Longueuil, Que.121-291.1611-0796 Mme / Mrs.Georgette Pérusse-Geoffroy, 1829 Aird.Montréal 404, Que.123-1117.1611-0816 Mme / Mrs.Georgette Pérusse-Geoffroy, 1829 Aird, Montréal 404, Que.123-1118.1681-1085 Aeneid Holdings Ltd., 2015 Drummond, chambre 200.Montréal 107, Que.Une partie du lot originaire 126, contenant une superficie A part of original lot 125, having an area of 33,845 square de 33,845 piedB carrés, mesure anglaise et plus ou moins, feet.English measure and more or less, and bounded as et bornée comme suit, savoir: au nord par le lot 125-868, au follows, to wit: on the north by lot 126-868.on the south by sud par le lot 125-870, à l'est par le lot 125-869, et à l'ouest lot 126-870, on the east by lot 125-869, and on the west by par le lot 125-886.lot 126-886.1195-0496 Mlle / Miss.Françoise Verreault.1465 Sherbrooke ouest, app.2304, Montréal 126-831.832-1.109.Que.1681-0496 M.Gérard Bergeron.77 Hébert, Sorel, Que.126-880.881-1.1681-0605 M.Gérard Bergeron.77 Hébert, Sorel, Que.126-881-2, 882.1196-0530 M.Jacques Duret, 1630 McGill.Longueuil.Que.126-892.893-1.1196-0520 M.Jacques Duret.1630 McGill, Longueuil.Que.126-893-2.894.1181-0103 M.Antoine Polidori, 166 Devonshire.Greenfield Park, Que.128-37.1181-0113 \u2022 M.Antoine Polidori.166 Devonshire.Greenfield Park, Que.128-38.0986-2563 M.Urbain Bergeron, 70 Beaubien ouest.Longueuil, Que.128-73, 74, 75.1171-0076 M.Paul Casavant, 1145 Bagot.Longueuil, Que.130-27.28-1.1171-0085 M.Elie Casavant.85 Payette, Longueuil.Que.¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 130-28-2, 29.___ 1164-0360 Mme / Mrs.Malvina Gautreau-Gauvin, 360 boul.Wilson.Longueuil.Que.130-164.166-1, 131-224, 225-1.0969-2396 Mercury Realties Inc., 2015 Drummond, chambre 200.Montréal, Que.130-283, 284.0961-2367 M.Jo.Wilaon, 2367 Montarville, Longueuil, Que.131-72, 73, 74.0968-2382 Mercury Realties Inc., 2016 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.131-147, 148.1160-0070 M.Roch Moreau, 1664 Joliette, Longueuil, Que.13.2-124.' 125' 126' >33-8?3- 1000-2086 Mercury Realties Inc., 2015 Drummond, chamb.-e 200, Montréal, Que.132-168.1000-2066 M.Roch Moreau, 1664 Joliette.Longueuil.Que.132_1ii' ll.1000-2056 M.Roch Moreau.1664 Joliette, Longueuil, Que.132-173, 174.0991-1231 M.René Grégoire.1300 Lafayette, Longueuil, Que.133-117.1129-0201 M.Jean-Joseph Laforest, 201 Leblanc ouest, Longueuil, Que.133-143, 144, 133-56-1.0993-1206 M.André Bergeron.1225 St-Alexandre.Longueuil, Que.' \u2022 \u2022 15\u201e i§X- 161- 0989-2145 M.Marcel Giroux, a's-c/o Ans.Hypothécaire R£.Ltd., 8687 Mayrand.Mont- 133-788.real 308.Que._ 0994-2276 M.René Mayer.2276 Grant, Longueuil, Que.133-997.998.999.1164-0170 Au Petit Goret, 4363 Frontenac, Montreal 178.Que.133-1031.1032.1033. 3730 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Nom et adresse Description de l'immeuble F°li0 Name and addre,, Description of immovable 1164-0138 Au Petit Goret, 4363 Frontenac, Montréal 178, Que.Le lot 133-1035 et une partie du lot 133-1036, mesurant Lot 133-1035 and.a S3 Boulevard Wilson 133-92, et à l'est par une partie du lot 133-1043.by Wilson Boulevard 133-92, and on the east by a part of lot 133-1043.1164-0130 Au Petit Goret, 4363 Frontenac, Montréal 178, Que.Le lot 133-1037.et une partie du lot 133-1036, mesurant Lot 133-1037 and a part of lot 133-1036 measuring this said cettedite partie 15 pieds d6P largeur par toute la profondeur part 16 feet in width by ««^ *^°f;said lot Enghsh dudit lot, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme measure and more or lesti.and ^»~.^0Kj,MS11\"-*j suit, savoir: au nord par le lot 133-1037.au sud par le résidu on the north by lot 133-1037, on %.^hbyJher^,daeoi dudit lot 133-1036, à l'ouest par le boulevard Wilson 133-92, said lot 133-1036, on the west by Wilson Boulevard 133-92, et à l'est par une partie du lot 133-1043.and on the east by a part of lot 133-1043.0975-1241 M.Yvon Chenard, 1241 Daniel, Longueuil.Que.J?4-7™ 0981-1201 M.Roger Connell.1201 Brébeuf, Longueuil, Que.Jo*-MW.0968-2140 M.Henri Cousineau, 1319 Chemin Chambly.Longueuil.Que.,,c i,2' i,o \u201e,Q 0969-1675 M.John Hadzurik, 1577 McGill, Longueuil.Que.I?5\"?!!' Z78, Z7a' 0965-2305 Alphonse Bélanger Inc., 327 Leblanc ouest, Longueuil.Que.135-525.0966-2316 Alphonse Bélanger Inc.327 Leblanc ouest, Longueuil, Que.îïcto?' 0965-2325 Alphonse Bélanger Inc., 327 Leblanc ouest, Longueuil, Que.««Ho 0966-2335 Alphonse Bélanger Inc., 327 Leblanc ouest, Longueuil, Que.135-528.0965-2055 Silvic Enterprises Inc., 6 Belcourt Drive, Dollard-des-Ormeaux 970, Que.136-534.0965-2065 Silvic Enterprises Inc., 5 Belcourt Drive, Doliard-des-Ormeaux 970, Que.135-535.1124-0740 M.Fernand Giroux, 1064 Emma, Longueuil.Que.140-229, 235-1.1139-0819 M.Armand Gosselin, 821 Boul.Ste-Foy, Longueuil, Que.Les lots, 140-369, 140-370, 140-371, à distraire toutefois Lots 140-369, 140-370 and 140-371, to withdraw however the les parties expropriées pour l'élargissement du Boulevard Ste- expropriated parts for the widening of Ste-Foy Boulevard.Foy.0930-1664 M.Roch Moreau, 1664 Joliette, Longueuil, Que.140-656, 657, 658.0930-1990 Mlle / Miss.Elodia Dulude, 6266 Fabre, Montréal, Que.140-994, 9»5.1161-0831 M.Gaétan Hébert, 3439 Ste-Catherine ouest, Montréal 216, Que.et / and M.140-1028, 1029.1030.Roger Marin, 3101 Grande Allée, Greenfield Park.Que.et/and M.Denis Girouard, 1606 Bourbonnière, Montréal.Que.0930-2076 M.Paul Veilleux, 330 Scott.Longueuil, Que.140-1141,1142.0926-1548 M.Jean-Guy Crevier, 1548 Westgate, Longueuil, Que.141-163, 164, 178-3, 178-4.0925-1523 M.Arthur Traversy, 1535 Dollard, Longueuil, Que.141-181, 182.9025-1633 M.Arthur Traversy, 1633 Dollard, Longueuil, Que.141-183, 184.0919-1191 Mme/Mrs.P.Rocheleau-Richard, 1191 Cartier.Longueuil, Que.142-77, 80, 81.0918-2112 M.Marcel Deguire, 2112 Cartier, Longueuil, Que.142-733, 143-1060.0920-2638 M.René Coulombe, 3042 Routhier, Longueuil, Que.:.142-1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1088-2.1120-1120 M.Viateur Favreau, 1102 Josephine, Longueuil, Que.143-396, 397.1125-1137 M.André Lapointe, 1013 Delorimier, Longueuil, Que.143-404, 405.406-1.0912-0956 M.Robert Giroux, 960 Ste-Hélène, Longueuil, Que.Un emplacement, composé du lot 143-504-2, et des parties A site, composed of lot 143-604-2, and by parts of lots 143- des lots 143-506, 143-506 et 143-607, mesurant 46.6 pieds de 505,143-506, and 143-507, measuring 45.5 feet in width, having largeur contenant une superficie de 3,238 pieds carrés, mesure an area of 3,238 square feet, English measure and more or less, anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au and bounded as follows, to wit: on the north by the residue of nord, par les résidus desdits lots 143-605.143-506 et 143-507, said lots 143-505, 143-506 and 143-507, on the south, by the au sud, par la ligne sud du lot 143-504-2, à l'ouest par le lot south limit of lot 143-504-2, on the west by lots 143-504-3 and 143-504-3, et par une partie du lot 143-608 et à l'est, par la rue by a part of lot 143-508, and on the east by Ste.Hélène street.Ste-Hélène.0914-0934 M.Maurice Parenteau, 938 Préfontaine, Longueuil, Que.Un emplacement, composé des lots 143-652, 143-661, 143-653-10.143-675-4 et des parties des lots 143-650 et 143-675-6, mesurant 60 pieds de largeur, par 95 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord, par le résidu dudit lot 143-660, et par le lot 143-653-9, au sud, par une partie du lot 143-1708, et par les parties des lots 143-676 et 143-677, & l'est par la rue Préfontaine et à 1 ouest, par une partie du lot 143-676-6, les lots 143-653-11, et une partie du lot 143-663-12.A site, composed of lots 143-652, 143-651, 143-653-10, 143-676-4 and parts of lots 143-650 and 143-676-5, measuring 60 feet in width by 95 feet in depth, English measure and more of less, and bounded as follows, to wit: on the north, by the residue of said lot 143-650 and by lot 143-663-9, on the south by a part of lot 143-1708 and by parts of lot 143-676 and 143-677, on the east by Préfontaine street and on the west by part of lot 143-676-6, lots 143-663-11 and by a part of lot 143-653-12.0916-1940 M.René Coulombe, 3042 Routhier, Longueuil, Que.143-992, 993, 1009-6. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3731 Folio Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 0916-2010 Les Bonnes Entreprises Inc., 5466 Queen Mary road, suite 630, Montreal 248, Montreal 248, Que.Un emplacement, composé des lots 143-1034-1, 143-1035-1, A site.composed of lots 143-1034-1, 143-1035-1 and by parts et des parties des lots 143-1034-2, 143-1035-2, et 143-1036.of lots 143-1034-2.143-1035-2, and 143-1036, measuring 54.6 mesurant 64.6 pieds de largeur contenant une superficie de feet in width, having an area of 3,571 square feet, English 3,571 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, et bornée measure and more or less, and bounded as follows, to wit: on comme suit, savoir: au nord, par le lot 143-1033-2 et par une the north, by lot 143-1033-2 and by a part of lot 143-1033-3, partie du lot 143-1033-3, au sud par les résidus desdits lots 143- on the south, bv the residues of said lots 143-1034-2,143-1036-1034-2, 143-1035-2 et par une partie du lot 143-1036, à l'ouest 2 and by a part of lot 143-1036, on the west by another part of par une autre partie du lot 143-1036, et à l'est par la rue St- lot 143-1036 and on the east by St-George street.Georges.1159-1103 Mme / Mrs.Pierrine Zuliani-Martino, 8486 Stuart, Montréal 303, Que.143-1109-4.1158, 1159, 1160.0916-2072 M.Adrien Brunet, 2072 St-Georges, Longueuil, Que.143-1112.1113.0916-2401 M.Gaston Fournier, 2401 Préfontaine, Longueuil, Que.Un emplacement, composé des lots 144-621, 143-1389 et des A site, composed by lots 144-621, 143-1389 and by parts of parties des lots 144-622 et 143-1390, mesurant 45 pieds de lar- lots 144-622, and 143-1390, measuring 45 feet in width by 88 geur par 88 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou feet in depth, English measure and more or less and bounded moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par les lots 144- as follows, to wit: on the north by lots 144-1388 and 143-620, 1388 et 143-620, au sud par les résidus desdits lots 144-622 et on the south by the residues of said lotsl44-622 and 143-1390.143-1390, à l'est par les limites est des lots 143-1389 et 143- and on the east by the east limits of lots 143-1389 and 143- 1390, et à l'ouest par la rue Préfontaine 144-639.1390, and on the west by Préfontaine street 144-639.0916-2711 Caisse Populaire Desjardins de Montréal-Sud, 761 Ste-Hélène, Longueuil, Que.Un emplacement, composé des lots 143-1683, 144-874 et des A site, composed of lots 143-1683.144-874, and by parts of parties des lots 143-1684 et 144-875.mesurant 42 pieds de lots 143-1684 and 144-875, measuring 42 feet in witdh by 88 largeur par 88 pieds de profondeur, mesure anglaise, et plus ou feet in depth, English measure and more or less, and bounded moins, et bornée comme suit, savoir: au nord, par les lots 144- as follows, to wit: on the north, by lots 144-873 and 143-1682, 873 et 143-1682, au sud par le résidu desdits lots 143-1684 et on the south by the residues of said lots 143-1684 and 144-875.144-876, à l'est par la ligne arrière desdits lots 143-1683 et 143- on the east by the east limit of said lots 143-1683 and 143-1684 1684 et à l'ouest par la rue Préfontauie.and on the west by Préfontaine street.0914-1994 Gemini Construction Inc., 3042 Routhier.Longueuil, Que.144-286.287, 288, 291-10.0913-2443 M.Paul Landry, 313 Côte Nord, Ste-Thérèse ouest, Que.144-690.691.0914-2668 Mme / Mrs.A.Carrier Billette, 2568 Préfontaine, Longueuil, Que.144-785.786.0913-2693 M.Raoul Chabot, 2693 Ste-Hélène, Longueuil, Que.144-948-2, 949-2, 950-2.1187-1153 M.Marcel Proulx.1165 Maisonneuve.Longueuil, Que.144-867.858, 859.145-958.0911-1517 M.Claude Watier, 1517 Delorimier, Longueuil, Que.145-5-4, 6, 7.0910-1602 M.André Bertrand, et / and Mme / Mrs.Freda Lassueur, 2595 du Havre, 145-74, 76.Longueuil, Que.0911-1993 M.Marcel Hébert.300.5ième Rang, St-Ligori, Cté Montcalm, Que.145-329.0911-1997 M.Marcel Hébert, 300, 5ième Rang, St-Ligori, Cté Montcalm, Que.145-330.0911-2121 M.Lucien René Duclos, 2121 Delorimier, Longueuil.Que.145-450-15, 465.1160-1200 Mme / Mrs.P.Savard-Poitras, 1200 Beauregard.Longueuil, Que.146-643, 644.1162-1180 M.Charlemagne Bélanger, 3145 Jarry est, Montréal, Que.145-801, 802.803.0892-1806 M.Jacques Houle, 46 Goyette, Longueuil, Que.146-295A.296.147-492,493.0902-1524 M.Fernand Gagnon, adresse inconnue.146-489, 490.0901-1623 M.Fernand Beauchemin, 1613 Boul.Manseau, Longueuil.Que.146-492, 493.147-481, 482.0891-2127 Mlle / Miss Fernande et / and Mlle / Miss Aline Caron, 2127 8éguin, Longueuil, 147-127, 128, 119-12.Que.1135-1353 M.John Paskaryk, 1353 Green, Longueuil, Que.147-319, 320.0895-1575 M.J.E.Duval, 1673 Boul.Taschereau, Longueuil, Que.147-421,422.0895-1613 M.Fernand Beauchemin, 1619 Boul.Manseau, Longueuil, Que.147-449, 460.0896-1619 M.Fernand Beauchemin, 1619 Boul.Manseau, Longueuil, Que.147-J51, 452.0896-1733 Mme / Mrs.Eugenia Anders-Zieba, 77 LaGare.St-Philippe, Cté Laprairie, 147-527, 528, 629.Que.0882-2264 M.Paul Delage.2254 Ste-Jeanne-D'Arc, Longueuil, Que.148-287, 288.0879-2241 M.Maurice Thibault, 2241 St-Roch, Longueuil, Que.148-359, 360, 160-469, 470.0886-2465 Mercury Realties Inc.2015 Drummond.chambre 200, Montréal.Que.148-471.0930-0918 M.Jean-Paul Guilbault, 918 Joliette.Longueuil.Que.155-162.0929-0919 M.Jean Laçasse et / and Mme / Mrs.Yvette Vincent.5721, lOième Avenue, 155-251.Rosemont.Mtl, Que., \u2022 0928-0762 Mme / Mrs.Lucille Metras-Basque, 762 Marmier.Longueuil, Que .î°^297- 1112-0910 Comper Realty Inc., 6333 Décarie Blvd., chambre 140, Montréal 252, Que.155-433.0921-0461 M.Bernard Desjardins, 3855 Rocheleau, St-Hubert, Que.Les lots 157-65, 157-56 et une partie du lot 157-57, mesurant Lots 157-55, 157-56 and a part of lot 157-67, measuring this cettedite partie 22 pieds de largeur par 102.5 pieds de profon- said part 22 feet in width, by 102.5 feet in depth.English mea-deur, mesure anglaise, et plus ou moins, et bornée comme suit, sure and more or less and bounded as follows, to wit: on the eavoir: au nord, par le lot 157-66, au sud par le résidu dudit lot north by lot 167-56, on the south by the residue of said lot 157-67, à l'est par une partie du lot 157-27 et à l'ouest par la 157-57, on the east by a part of lot 157-27 and on the west by rue Marquette.Marquette street. 3732_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20__ 0914-0624 M.Henri Ménard, 5410 Orchard, St-Hubert, Que.158-32.0910-1094 M.Gérard Talbot, 1094 Delorimier, app.1.Longueuil, Que.\u201e\u201e.\u201e, *vs.sj Le lot 159-436, et une partie du lot 159-437, mesurant cette- Lot 159-436.and a part oUot.159437\u2022 me™e^h.^sa.d dite partie 20 pieds de largeur par 112 pieds de profondeur, me- part 20 feet in width by^^Me^^'^^tbS^S^ sure anglaise, et plus ou moine, et bornée comme suit, savoir.more or less, and boundedas follows to wion au nordTpar le lot 159-436.au sud par le résidu dudit lot 159- lot 159-436.on the south by the ««due\"J^if\"?^»^ 437, à l'est par la rue Delorimier.et à l'ouest par des parties the east, by Delorimier Street and on the west by parts of lots des lots 159-1140 et 159-1145-2.159-1140 and 159-1145-2.0911-1011 M.André Lapointe, 1013 Delorimier, Longueuil, Que.Le lot 159-490 et une partie du lot 159-489, mesurant cette- Lot 159-490.and a part of lot 159-48^9, measurmg this sa.d dite partie 15 pieds de largeur par 118 pieds de profondeur, me- part 15 feet in width by 118 feet in depth, English measure and sure anglaise et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: more or less, and bounded as follows, to wit.on the north, by au nord, par le lot 159-490, au sud par le résidu dudit lot 159- lot 159-490, on the south, by the residue of said lot 159-489, on 489, à l'est par la ligne est dudit lot, et à l'ouest par la rue De- the east, by the east limit of said lot 159-489 and on the west, lorimier.by Delorimier street.¦ _ 0896-0216 M.Albert Deburggraeve, 2158 Quinn Cr\u201e Ottawa 8, Ontario.J59-576 1103-1401 Mme / Mrs Rejeanne Tremblay-Cooke, adresse inconnue.159-58b, 587 0901-0141 M.André Sennett.141 Verchères.Longueuil, Que.îfrTïn4, ™f 1104-1406 Fidelity Developments Inc., adresse inconnue.159-7U7, /o» 0895-0935 M.Gérard Leblanc, 935 Boul.Taschereau, Longueuil, Que.Les lots 159-928, 159-929 et 159-940-22 à distraire toutefois Lots 159-928, 169-929 and 159-940-22, to withdraw however les parties servant de rues.the parts used as streets.0888-1120 Mercury Realties Inc., 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107.Que.160-287, 288 0887-0229 M.René Legault, 1471 Providence, Longueuil.Que.160-715A-1, 731, 732 1577-1145 Mme / Mrs.Janine Hébert-Lagarde, 4169 St-Hubert, Montréal, Que.201-471, 472-1 1582-3550 M.Ben Lechter, 2015 Drummond.chambre 200.Montréal 107, Que.Une partie du lot originaire 307, contenant une superficie de A part of original lot 307, having an area of 36,475 square 36,476 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et bornée feet, English measure and more or less, and bounded as follows, comme suit, savoir: au nord et au sud, par d'autres parties to wit: on the north and south, by other parts of said lot 307, dudit lot 307, à l'est et à l'ouest par des parties du lot original- and on the east and west, by parts of original lot 115.re 115.3101-2286 M.O.J.Valea, 2285 de la Métropole.Longueuil.Que.327-26 3106-2370 M.L.Claude Mercure, Syndic à la faillite Placage Industriel, Tour de la 327-37-2-1 Bourse, suite 804, Montréal, Que.3109-2605 Les Entreprises Larjac Inc.2605 Jean-Désy.Longueuil, Que.327-56 Addenda 3012-0190 Mme / Mrs Pauline Archambault-Hébert, 190 Arsène, Longueuil, Que.7-18 3016-0100 M.Roger Boulay, 100 Martin, Longueuil, Que.8-51 1234-2280 M.John Bacall, 926 North-Normandie Avenue.Hollywood, California, 90029, U.S.A.Une partie du lot originaire 51, contenant une superficie de A part of original lot 51, having an area of 2,248,848 square 2,248,848 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins, et feet.English measure and more or less and bounded as follows, bornée comme suit, savoir: au nord-ouest, par le Chemin du to wit: on the northwest, by a street Chemin du Lac, on the Lac, au sud-est par une autre partie du lot 51, au nord-est par southeast by another part of lot 51, on the northeast by a part une partie du lot originaire 50 et de l'autre côté par le lot 52.of original lot 50 and on the other side by lot 52.2822-1710 Mme / Mrs Simone Bacon-Alarie, 1710 Baffin, Longueuil, Que.69-179, 74-109 1303-2201 M.Marcel Bérard, 535 Aird, Montréal, Que.91-199, 200, 201, 202, 203, 204, 205.1304-2370 M.Adélard Robert.2370 Lavallée, Longueuil, Que.Le lot 93-57 et une partie du lot 93-56, mesurant cettedite Lot 93-57, and a part of lot 93-56, measuring this said part partie 21 pieds de largeur par 90 pieds de profondeur, mesure 21 feet in width by 90 feet in depth English measure and more anglaise et plus ou moins, et bomée comme suit, savoir: au or less, and bounded as follows, to wit: on the north, by the nord par les résidus dudit lot 93-56, au sud, par le lot 93-57, à residue of said lot 93-56, on the south by lot 93-57, on the east I est par la rue Lavallée 93-94 et à l'ouest par une partie du lot by Lavallée Street 93-94 and on the west by a part of lot 93-58.93-58.0927-2069 M.Jean-Guy Héroux, 364 Rouillard, Longueuil, Que.0928-2150 M.Jean-Guy Héroux, 364 Rouillard, Longueuil, Que.140-1226-1.1226-2, 1201-5, 141-730-1,731,732,733.765-1, 766-2 140-1220, 1221, 1226-20.et la partie du lot 140-1226-21 and the part of lot 140-1226-21.Nom et adresse Description de l'immeuble F0li° Name and addree.Description of immovable GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n\" SO 3733 Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes Sale of immovables for the non-payment of taxes Deuxième partie Second Section Immeubles sujets au droit de retrait d'un an Immovables subject to the one-year right of withdrawal (Lea lota ci-après décrite sont du cadastre officiel du Village de Longueuil Inc., dans les limites de la Ville de Longueuil) (The lots hereinafter described are from the official cadastre of Village of Longueuil.Inc., within the limits of the City of Longueuil) Nom et adresse Description de l'immeuble Folio Name and address Description of immovable 1061-0175 Mme / Mrs.Julien Poirier, 85 Lareau, Longueuil, Que.Le lot 37-281 du cadastre de la paroisse St-Antoine-de-Lon- Lot 37-281 of the Parish of St.Antoine-de-Longueuil and lot gueuil et le lot 1-307, du Village de Longueuil Inc.1-307 of the Village de Longueuil Inc.1059-0175 M.Roger Turcotte, 83 Pratt, Longueuil, Que.1-331 1082-0320 M.Gaétan Baillargeon, 118 D'Anjou, Longueuil, Que.1-358 0978-0040 Club Social de la Rive-Sud Inc., 16 St-Sylveetre, Longueuil, Que.Une partie du lot 187, contenant une superficie de 37,165 A part of lot 187, having an area of 37,165 square feet, pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, et bornée com- English measure and more or less, and bounded as follows, to me suit, savoir: au nord et à l'est, par d'autres parties dudit wit: on the north and east, by other parts of said lot 187, on lot 187, à l'ouest par une partie du lot 400 (rue) et au sud par the west by lot 400 (street) and on the south by lots 189 and les lots 189 et 188-3.188-3.0961-0585 M.Gaétan Baillargeon, 118 D'Anjou, Longueuil, Que.Une partie du lot 199-149 mesurant 50 pieds de largeur par A part of lot 199-149, measuring 50 feet in width by 78 feet 78 pieds de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, et in depth, English measure and more of less, and bounded as bornée comme suit, savoir: à l'est par le Boulevard Quinn, à follows, to wit: on the east by Quinn Boulevard, on the west l'ouest par le résidu dudit lot 199-149, au nord, par le lot 199- by the residue of said lot 199-149, on the north by lot 199-150.150.et au sud par le lot 199-148.and on the south by lot 199-148.1044-0430 M.Dieter Hansel, 170 Bienville, Longueuil, Que.200-664 1006-0032 Fabrique de Longueuil, a/s-c/o Les Ateliers du Vieux Lg.Ltée, 22 St-Charles Ouest, Longueuil, Que.Un emplacement, composé des parties des lots 210 et 211, A site, composed of parts of lots 210 and 211, having an contenant une superficie de 11,000 pieds carrés mesure anglaise, area of 11,000 square feet, English measure and more or less, et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par la and bounded as follows, to wit: on the north, by St-Charles rue St-Charles, au sud.par d'autres parties desdits lots 210 et street, on the south by other parts of said lots 210 and 211, on 211, à l'ouest par une partie du lot 212.et à l'est, par une autre the west by a part of lot 212, and on the east, by another part partie dudit lot 210.of said lot 210.0992-0380 Mme / Mrs.Thérèse Lachance-D'Amour, 180 St-Alexandre, Longueuil.Que.Les lots 335-3 et 335-5 à distraire toutefois la partie servant Lots 335-3 and 335-5, to withdraw however the part used de rues.as streets.0994-0510 Préfontaine » Fils Ltée, 224 Grant, Longueuil, Que.Un emplacement, composé des lots 348-254,348-265,348-267 A site, composed of lots 348-254, 348-255.348-257 and parts et des parties des lots 348-256 et 348-266.contenant une of lots 348-256 and 348-266.having an area of 23,188 square superficie de 23.188 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou feet.English measure and more or less, and bounded as fol- moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par le lot 348-258 lows, to wit: on the north, by lot 348-258 and by a part of lot et par une partie du lot 348-267, au sud, par le lot 351, à l'est 348-267, on the south by lot 361, on the east by Grant street, par la rue Grant, et à l'ouest par les résidus desdits lots 348-256 and on the west by the residues of said lots 348-256 and 348- et 348-266, mesure anglaise.266.0993-0605 M.Michel Gagnon, 166 Brixton, St-Lambert, Que.Un emplacement, composé des lots 348-264, 348-266, et des A site, composed of lots 348-264, 348-265, and by part of parties des lots 348-256 et 348-266, contenant une superficie de lots 348-256 and 348-266, having an area of 19,405 square feet, 19,405 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou moins, et bor- English measure and more or less, and bounded as follows, to née comme suit, savoir: au nord, par une partie du lot 348-267, wit: on the north, by part of lot 348-267, on the south by lot au sud par le lot 361, à l'est, par les résidus desdits lots 348-266 351, on the east by the residues of said lots 348-266 and 348- et 348-256, et à l'ouest par la rue StrAlexandre.256 and on the west by St.Alexandre street.1036-0185 M.André Besnard, 79 De Gentilly Ouest, Longueuil, Que.348-343 1018-0316 M.Gaétan Baillargeon, 118 D'Anjou, Longueuil, Que.348-546 3734 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes Sale of immovables for the non-payment of taxes Troisième partie Third Section Immeubles non-sujets au droit de retrait d'un an Immovables non-subject to the one-year right of withdrawal (Les lots ci-après décrits sont du cadastre oSciel de la paroisse St-Antoine de Longueuil dans les limites de la Ville de Longueuil) (The lots hereinafter described are from the official cadastre of the Pariah of St-Antoine de Longueuil within the limits of the City of Longueuil) Folio Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 2326-0690 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal.Que.15-3 2320-0620 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond.chambre 200.Montréal 107, Que.16-1 2320-0650 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond.chambre 200, Montréal 107, Que.15-7 2326-0700 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.16-8 2318-0580 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200.Montréal 107, Que.16-12 2317-0537 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200.Montréal 107.Que.15-15 2326-0768 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond.chambre 200, Montréal 107, Que.Le lot 15-27.à distraire toutefois la partie appartenant » Lot 15-27.to withdraw however the part belonging to Mr-M.Gilbert Gonthier ou représentant.Gilbert Gonthier or representative.2317-0487 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200.Montréal 107, Que, 16-39 2318-0440 M.Benjamin H.Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.15-43 2326-0260 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.15-47 2316-0462 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.16-48 2326-0280 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond, chambre 200, Montréal 107, Que.15-52 2316-0502 M.Benjamin H.Lechter, 2015 Drummond.chambre 200.Montréal 107.Q»é.16-51 2325-0815 M.Benjamin H.Lechter.2015 Drummond.chambre 200, Montréal 107, Que.16-66 1234-1342 M.Ben Lechter.2015 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.21-87, 88 1234-1290 M.K.Pila.5605 Greenwood.Côte St-Luc.Que.21-100, 101, 27-43A, 44a 1234-1288 M.Ben Lechter.2016 Drummond.chambre 200.Montréal 25, Que.21-101A.27-45A 1234-1330 M.Ben Lechter.2016 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.Une partie du lot originaire 27, contenant une superficie de A part of original lot 27, having an area of 4,250 square feet, 4,250 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins et bornée English measure and more or less and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par le Chemin du Lac, au sud par wit: on the north by Chemin du Lac, on the south by a part une partie du lot 27-34A, à l'est par le lot 27-31A, et à l'oueat of lot 27-34A, on the east by lot 27-31A and on the west by a par une rue 27-39A.street 27-39A.1234-1320 M.Ben Lechter, 2016 Drummond, chambre 200, Montréal 25, Que.27-62A 2310-0358 Mlle / Miss M.V.Cavers, et / and M.A.R.Cavers, 705 Querbes, Outremont.27-1202, 1203 Que.2307-0349 Mile / Miss M.V.Cavers, et / and M.A.R.Cavers, 705 Querbes, Outremont.27-1268, 1269, 1270, 1271 Que.1238-0750 M.Jose-Carlos 8imoea, CP.693.Gait, Ont.34-669.570 2705-2487 M.Napoléon Croteau.et/and M.Réal Crotesu, 2194 Laurier, Longueuil, 66-20, 21 Que.2703-2443 M.Lionel Liquornik, 6788 Melling.Côte St-Lue.Que.66-88 91 2704-2160 M.Gaston Bouchard.1340 Ste-Hélène, Longueuil, Que.66-372 1231-0841 M.René Coulombe, 3042 Routhier.Longueuil.Que.66-89,90 1232-1010 M.René Coulombe, 3042 Routhier.Longueuil, Que.66-313, 314 1231-1023 M.René Coulombe, 3042 Routhier, Longueuil, Que.66-360, 361 1231-1029 M.René Coulombe, 3042 Routhier, Longueuil, Que.66-362, 363 1312-1660 Amer Papson Limited & Al., 480 Roslynn.Westmount, Que.67-16 1311-2163 Mercury Realties Inc.2016 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.a l'irT P\",rtie du,lot originaire 70, contenant une superficie de A part of original lot 70.having an area of 4,250 square feet.4,250 pieds carrés mesure anglaise et plus ou moins, et bornée English measure and more or leas, and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une rue 70-534A, au sud, à wit: on the north by a street 70-534A, on the south, east and 1 est et à 1 ouest par d'autres parties du lot originaire 70.west by other parts of original lot 70.1311-2161 Mercury Realties Inc.2015 Drummond.chambre 200.Montréal.Que.70-80 1311-2215 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.71-434 1311-2297 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.71-636, 637,638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3735 Nom et adresse Description de l'immeuble Folio Name and address Description of immovable 1311-2387 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montras)!, Que.71-743, 744, 745 1311-2383 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.71-746, 747.748 1311-2381 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.71-749, 750, 751 1311-2377 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920.Montréal, Que.71-754, 755 1311-2373 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920.Montréal.Que.71-756,757.758 1311-2371 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.Le lot 71-759, à distraire toutefois la partie expropriée, Lot 71-759, to withdraw however the expropriated part.1311-2283 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.Le lot 71-760, à distraire toutefois la partie expropriée.Lot 71-760.to withdraw however the expropriated part.1311-2337 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920, Montréal, Que.,.71-761 1311-2277 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920, Montréal, Que.Les lots 71-772 et 71-773, à distraire toutefois les parties Lots 71-772 and 71-773.to withdraw however the expro-expropriées.priated parts.1311-2275 M.Lazarus Bavitch.1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.Les lots 71-774 et 71-788, à distraire toutefois les parties Lots 71-774 and 71-788, to withdraw however, the expro-expropriées.priated parts.1311-2291 M.Lazarus Bavitch.1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.71-775 1311-2273 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre 920, Montréal, Que.Les lots 71-786 et 71-787, à distraire toutefois les parties Lots 71-786 and 71-787, to withdraw however the expro\" expropriées.priated parts.1311-2269 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920.Montréal, Que.71-799, 800 1311-2267 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920.Montréal, Que.71-801, 813 1311-2265 M.Lazarus Bavitch, 1 Place Ville-Marie, chambre920, Montréal, Que.71-811, 812 1367-0141 M.Armand Hébert, 9151 Lasalle, Ville Lasalle, 403, Que.83-5 1360-0658 M.Armand Hébert, 9151 Lasalle, Ville Lasalle 403, Que.83-18 1357-0325 M.Armand Hébert, 9151 Lasalle, Ville Lasalle 403, Que.83-43 1389-0311 M.Gaston Bouchard, 1340 Ste-Hélène, Longueuil, Que.86-517 8000-0118 M.E.Tousignant, adresse inconnue.a) Une partie du lot originaire 94, bornée au nord par la (a) A part of original lot 94, bounded on the north by the ligne limitative des terres 93 et 94, au sud par les lots 94-1582, limiting line of lots of lands 93 and 94, on the south by lots 94-727 à 734 inclusivement, et par une partie du lot 94-1471, à 94-1582.94-727 to 94-734 inclusively and by a part of lot 94-l'est par une partie du lot 94-1471.et à l'ouest par la rue 1471, on the east by a part of lot 94-1471 and on the west by Gamache.Gamache street.b) Une autre partie du lot originaire 94, bornée au nord par (6) Another part of original lot 94, bounded on the north la ligne limitative des terres 93 et 94, au sud.par les lots 94-3, by the limiting line of lots of lands 93 and 94, on the south by 94-4, et 94-402 à 94-431 inclusivement, à l'est par une partie lots 94-3, 94-4 and 94-402 to 94-431 inclusively, on the east by du lot 94-435 et à l'ouest, par une partie du lot 94-401.a part of lot 94-435 and on the west by a part of lot 94-401.Les deux emplacements contiennent une superficie de The both sites having an area of 6.654 square feet all from 6,654 pieds carrés, tous de la mesure anglaise, et plus ou moins, the English measure and more or less.1425-0115 Omega Investments Ltd., 455 Michel-Jasmin, Dorval 740, Que.Une partie du lot 94-1294, mesurant 28 pieds de largeur par A part of lot 94-1294, measuring 28 feet in width, by 100 100' de profondeur, mesure anglaise, et plus ou moins, et feet in depth, English measure and more or less, and bounded bornée comme suit, savoir: au nord, par une partie du lot as follows, to wit: on the north, by a part of lot 94-1297, on 94-1297, au sud par une rue, à l'est par le lot 94-1295.à l'ouest the south by a Street, on the east by lot 94-1295 and on the par le résidu dudit lot 94-1294.west by the residue of said lot 94-1294.1422-0114 Omega Investments Ltd., 455 Michel-Jasmin, Dorval 740, Que.Une partie du lot 94-1297, mesurant 28 pieds de largeur par A part of lot 94-1297.measuring 28 feet in width by 99 feet 99 pieds de profondeur, mesure anglaise, et plus ou moins, et in depth, English measure and more or less, and bounded as bornée comme suit, savoir: au nord, par la rue Jules-Roche, follows, to wit: on the north by Jules-Roche street, on the au sud par une partie du lot 94-1294, à l'est par le lot 94-1296 south by a part of lot 94-1294.on the east by lot 94-1296 and et à l'ouest par le résidu dudit lot 94-1297.on the west by the residue of said lot 94-1297.1639-0599 Corporation Credit Richelieu, 247 Victoria, Longueuil, Que.120-116-3 1173-0069 Mercury Realties Inc., 2015 Drummond, chambre 200, Montréal.Que.129-39 0929-2385 Substantial Developments of Montreal Ltd., adretse inconnue.Une partie du lot originaire 130, enclavée, contenant une A part of original lot 130, enclaved, having an area of 2,840 superficie de 2,840 pieds carrés, mesure anglaise, et plus ou square feet English measure and more or less, and bounded moins, et bornée comme suit, savoir: au nord par les lots 131- as follows, to wit: on the north by lots 131-393, 131-392 and 393, 131-392 et une partie du lot 131-324, à l'est et au sud-est apart of lot 131-324, on the east and southeast by lot 130-813-1 par le lot 130-813-1 et au sud-ouest, par une partie du lot and on the southwest by a part of lot 130-816-3, and by lots 130-816-3, et les lots 130-816-2-2, 130-816-2-1, 130-816-1.130-816-2-2.130-816-2-1, 130-816-1, 130-816-2-2, and 130-816-130-815-2-2, et 130-816-2-1.2-1. 3736 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971,, Vol.106, No.SO Folio Nom et adresse Name and addreie Description de l'immeuble Description of immovable 0973-2425 Mercury Realties Inc., 2016 Drummond, chambre 200, Montréal, Que.Î2°r!n2« 1164-0144 Au Petit Goret, 4363 Frontenac.Montréal 173, Que.!,?\"AVu 8000-0036 Mercury Realty Inc.2016 Drummond, chambre 200, Montréal.Que.iiaAaa 1144-0580 Mercury Realties Inc., 2015 Dmmmond, chambre 200, Montréal, CJué.îxsîï?0946-1774 Mercury Realties Inc., 2016 Drummond, chambre 200.Montréal, Que.138-577 1147-0633 Mercury Realties Inc.2015 Drummond, chambre 200.Montréal.Que.Les lots 138-666 et 138-667.à distraire toutefois de ces lots Lots 138-666 and 138-667.to withdraw however from those les parties expropriées.La superficie de ces lots mis en vente lots the expropriated parts.The area of those lots put up on est de 489 pieds carrés.sale is 489 square feet.0945-1973 M.Rolland Leblanc, adresse inconnue.î38.\"?8.2.\"2' 138~683_ 2 0920-1624 Mlle Elodia Dulude.6266 Fabre, Montréal, Qjé.MtSS 0920-1630 Mlle Elodia Dulude, 5266 Fabre.Montréal.Que.M2\"228 0919-2083 M.Michel Viger.401 Goyette.Longueuil.Que.142-688 0922-0466 M.Lionel Chevalier, 96 Gardenville, Longueuil, Que.Une partie du lot 157-33.mesurant cettedite partie 3 pieda A part of lot 157-33, measuring this said part 3 feet in de largeur par 101.5 pieds de profondeur, mesure anglaise et width by 101.5 feet in depth, English measure ana more or plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au sud par le less, and bounded as follows, to wit: on the south by the résidu dudit lot 157-33, au nord par le lot 157-34, à l'est parla residue of said lot 157-33, on the north by lot 157-34.on the rue Duvernay et à l'ouest par une partie du lot 157-51.east by Duvernay Street, and on the west by a part of lot 167- 61.0896-0830 Mme / Mrs Lionel Turcotte, adresse inconnue.Le lot 160-6-13.et une partie du lot 160-6-14.enclavée con- Lot 160-6-13 and a part of lot 160-6-14, enclaved having an tenant une superficie de 400 pieds carrés, mesure anglaise, area of 400 square feet, English measure and more or less, and et plus ou moins, et bornée comme suit, savoir: au nord parle bounded as follows, to wit: on the north by lot 160-6-13, on lot 160-6-13, au sud par le lot 160-6-14-1.à l'est par la ligae the south by lot 160-6-14-1, on the east by the limiting line of limitative des terres 159 et 160, et à l'ouest, par la ligne ouest lots of lands 159 and 160, and on the west by the west limit dudit lot 160-6-14.of said lot 160-6-14.En foi de quoi, j'ai signé ce présent document, ce septième jour de mai, mil neuf cent soixante-quatorze.Le greffier, 57198-20-2-o Claude Gauthier.In testimony whereof, I have signed this present document, this seventh day of May 1974.Claude Gauthier, 57198-20-2-q Clerk.Corporation du comté de Châteauguay Avis public est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier du conseil de comté, que JEUDI, le ONZIÈME jour de juillet 1974, à DIX heures de l'avant-midi, à Sainte-Martine, dans la salle du Conseil de comté, les immeubles suivants seront vendus £our arrérages des taxes dus sur chacun de ces imraeu-les, avec les frais encourus, à moins que le tout ne soit payé avant la vente.Corporation of the County of Châteauguay Public notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer for the County Council, that THURSDAY, the ELEVEN day of JULY 1974, at TEN o'clock in the morning at Ste-Marline, in the hall of the County Council, the following immovable properties will be sold for arrears of taxes due on each of these properties, with cost incurred, unless paid in full before the sale.Corporation municipale de St-Malachie d'Ormstown \u2014 Municipal Corporation of St.Malachie d'Ormstown Propriétaire\tCadastre\tTaxes munie.\tTaxes scolaires\tTotal Owner\tCadastral\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Henderson, Bessie.P.61.S 14.60 S 103.25 I 117.86 Commission scolaire de Huntingdon et Village de Ormetown \u2014 Huntingdon School Board and Village ofOrmstown Tremblay.Roland, Ormstown P.631 S 364.18 * 221.60 t 685.78 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1971,, 106' année, n' SO 3737 Corporation municipale du Village de St-Chrysostôme \u2014 Municipal Corporation of the Village of St-Chrysostôme Propriétaire\t\tTaxes\tTaxes\t \tCadastre\tmunie.\tscolaires\t \t\t\t\tTotal Owner\tCadastral\tMunie.\tSchool\t \t\ttaxée\ttaxes\t \t\tt 300.30\tS 577.64\t$ 877.94 \t\t145 42\t107.60\t253.02 \t\t\t\t Corporation municipale de la paroisse de St-Jean Chrysostôme \u2014 Municipal Corporation of the Parish of St-Jean Chrysostôme Parent, Louis Suce.319.% 1.65 S 6.35 S 8.00 Bourdeau, Donat.P.668 .29.70 126.27 155.97 Corporation municipale de la paroisse de Ste-Clotilde \u2014 Municipal Corporation of the Parish of Ste-Clotilde Bryant, Charles & Marcil, Edna.P.950.Carubia, Filippo :.P.933.Guay, Donald.P.195.Goulet, Rolland.P.176.Lalonde, Yves.1286 à-to 1293____ Legault, Rosaire.188-43.Bourdeau, Raymond.P.951.Clermont, Gérard.184.Cloutier, Louis-Philippe.P.949.Faubert, Jean-Louis.P.170.Hickey, William Louis.P.142.Marcil.Claude.P.193.Daoust.Jean Guy & Succ.R.Prud'homme.P.944.Les Terres Noires.22-23-24-25.36.94\tt 173.10\tS 210.04 27.66\t102.23\t129.89 7.90\t17.13\t25.03 81.40\t156.01\t237.41 280.53\t802.70\t1,083.23 35.75\t32.19\t67.94 162.08\t1.835.20\t1,997,28 561.80\t1.484.22\t2.046.02 \t41.37\t41.37 \t406.13\t406.13 7.35\t142.65\t149.90 \t922.97\t922.97 \t173.56\t173.56 208.41\t1,289.80\t1,498.21 Corporation municipale de la paroisse de Ste-Martine \u2014 Municipal Corporation of the Parish of Sainte-Martine Hébert.Ernest.310-26,310-27, P.25 S 1,245.55 * 720.83 t 1,966.38 Laberge, Jean-Paul.169-11,12.272.92 429.95 702.87 Corporation municipale de St-Paul-de-Châteauguay \u2014 Municipal Corporation of St-Paul-de-Châteauguay Hébert, J.Fernand.95.$ 92.95 S 870.55 $ 963.50 Corporation municipale de la paroisse du Très St-Sacrement d'Howick Municipal Corporation of the Parish of Tris St-Sacrement of Howick Demers, Josephat & al.438 à-to 443 .8 182.55 S 841.76 $ 1,024.31 Réjeanne, Holding.P.362.253.20 253.20 Lamarre, Marielle, épouse de-wife of Collin Williams.P.435.140.08 415.29 556.09 Lamarre, Marielle, épouse de-wife of Collin Williams.421-422.147.13 135.40 282.53 Corporation municipale delà paroisse de St-Urbain Premier\u2014 Municipal Corporation of the Parish of St-Urbain Premier Garand, Gilles P.245.* 325.92 S 325.92 3738 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1971,, Vol.106, No.20 Commission scolaire Lévîs Sauvé et Ville Mercier \u2014 Lévis Sauvé School Board and Ville Mercier Propriétaire\tCadastre\tTaxes munie.\tTaxes scolaires\tTotal Owner\tCadastral\tMunie, taxes\tSchool taxes\t Gervais, Lorenzo.Grzywinski, V.Wit.Grzywinski, V.Wit.Lemire.André et-and Boucher, Jean-Koch Rohaly, Paul.Rohaly, Mme-Mrs Viola.Esno Corp.Esno Corp.Osborne Ent.ltée.P.38.$ 198.90 S 352.76 t 551.66 191, P.111.31.82 21.43 53.25 191-162 .36.97 28.24 65.21 217-20.29.58 17.33 46.91 P.127 .26.34 62.00 88.34 P.127 .32.95 73.28 106.23 P.33.10,015.96 5.802.19 15,818.15 P.36.4,336.31 3,642.08 7,978.39 P.127-128, 130 ____ 170.47 170.74 Donné à Ste-Martine, le 6 mai 1974.Le Sccrétdire-trêsorier, 57255-20-2-o A.Langis, Given at Ste-Martine, May 6, 1974.A, Langis 5725S-20-2-o Secretary-treasurer.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives\tDepartment of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Administrateurs\tDirectors Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs whose names follow have changed the number of their directors tel qu'indiqué ci-après.as indicated hereinafter.\t Nom de la Compagnie Name of Company\tDate de Nombre d'administrateurs constitution Number of directors Date of _ Ancien nombre Nouveau nombre incorporation Previous number New number ALLIED TRAVEL BUREAU LIMITED.04 09 63 3622-63 BRAULT, GUY, CHAPUT INC.31 12 64 21-65 CALAMCA LTEE.28 0 6 73 CALAMCA LTD.731802 CAR-PARK INC.05 11 67 13386-57 CHICOUTIMI CHRYSLER-PLYMOUTH LTEE .06 02 68 579-68 CLEMENT & CLEMENT INC.03 06 64 11442-64 LA COMPAGNIE MANUFACTURIERE DE 14 06 73 JOAILLERIE ELEGANCE INC.737llï* JBWELLERY MFa- c0- INC- C0£TINENTAL DISCOUNT CORPORATION .06 07 65 CORPORATION D'ESCOMPTE CONTINENTAL lo017-54 3 11 3 6 13 6 3 4 12 6 3 S 3 4 11 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° 20 3739 Date de constitutions Nom de la Compagnie Name of Company Date of incorporation CONTINENTAL DISCOUNT CORPORATION .06 07 66 CORPORATION D'ESCOMPTE CONTINENTAL 13017-64 DUBUISSON EXPLORATIONS LIMITED.10 10 36 2279-36 E.T.D.(ETUDE8 ET TRAITEMENT DES 24 12 69 DONNEES) INC.6306-69 ELECTRI-TEST INC.28 08 67 3469-67 LES ENTREPRISES VAQUET INC.24 05 66 2188-66 ERGE INC.13 04 72 7212-71 FIDUSCO LTD.24 02 66 883-66 FORMO INC.13 04 53 6891-53 GAGNON.CHABOT, LABRECQUE INC.11 10 72 725657 LES GALERIES JEAN-TALON INC.24 01 74 740369 GARAGE GILLES & PIERRE CHARBONNEAU 08 11 72 INC.729314 GENERAL FINANCE CORPORATION INC.07 10 71 CORPORATION DE FINANCE GENERALE INC.716301 GRAMCO LIMITED.21 06 60 12767-60 HASHMAN CONSTRUCTION (QUEBEC) LTD.21 04 71 2080-71 HAUTE COIFFURE LESLIE INC.10 03 70 1068-70 HEROUX LIMITED.17 03 42 2088-42 INDUSTRIAL FOAM CONVERTERS (1972) LTD.13 07 45 4407-46 LES IMMEUBLES BEAUPRE INC.17 09 71 714922 IMMEUBLES JOURNAUX LIMITEE.01 05 68 2005-68 LES INDUSTRIES DU HOCKEY CANADIEN 06 10 69 INC.CANADIAN HOCKEY INDUSTRIES INC.4737-69 LES INVESTISSEMENTS ASTREC LTEE.23 01 68 362-68 Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Previous numoer Nouveau nombre New number 13 3740 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Date de constitution Nom de la Compagnie Same of Company t Date of incorporation LES JOURNAUX TRANS-CANADA LTEE.21 03 87 TRA SS-CA S ADA NEWSPAPERS LTD.1181-67 KING EDWARD PARK AND AMUSEMENT 03 04 12 COMPANY 202-12 LACHANCE 4 FORTE INC.07 06 66 11339-66 LAMAC INVESTMENTS LTD.02 07 64 11643-64 JOSEPH LEMAY & FILS INC.19 11 68 6480-68 LOISIRS ST-LOUIS-DE-GONZAGUE DE 09 01 73 MONTREAL 730087 LOISIRS TOURBILLON STE-THERESE INC.06 12 71 716680 MACDONALD TOBACCO INC.23 12 30 2361-30 THE MARTINIQUE MOTOR IS S LTD.21 03 63 MOTEL LE MARTINIQUE LTEE 1279-63 METROPOLITAN TIRE RETREADER8 CORP.08 11 65 4914-65 MODE SELECT INC.31 08 66 3889-65 MORNE ENTERPRISES INC.01 03 72 721199 MUSEE HISTORIQUE DE L'ELECTRICITE.21 12 64 ELECTRICAL HISTORICAL MUSEUM 6366-64 SORMASDIE SHOPPJSG CESTRE LTD.18 07 60 CENTRE D'ACHATS NORMANDIE LTEE 13101-60 LE NOUVELLISTE LTEE.27 12 67 5379-67 ORPHEUM BUILDING INVESTMENTS LTD.20 07 66 3008-66 PLACE QUEBEC INC.12 06 64 2698-64 LES PLACEMENTS MONOR INC.04 04 61 MONOR INVESTMENT INC.11663-61 QUEBEC GUNITE MARINE INC.06 04 68 1678-68 LES RESTAURANTS LA NOUVELLE ORLEANS 24 05 62 INC/.12269-62 BAW)N ADRIEN DE PARIS INC.06 09 68 4063-68 Nombre d'administrateurs Number of director! Ancien nombre Previous number Nouveau nombre New number M 3 « 0 4 3 7 4 8 5 8 ¦1 14 7 6 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3741 Date de Nombre d'administrateurs constitution Number of director! Nom de la compagnie -;- Name of Company Date of Ancien nombre Nouveau nombre incorporation Previous number New number SELECT PRESS LTD.PRESSES SELECT LTEE 968-67 SERVICE DE DOCUMENTATION JURIDIQUE (SEDOJ) INC.716344 SERVICE DES LOISIRS DE LA CATHEDRALE DE MONTREAL 730360 SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DE L'EST DU QUEBEC LTEE 716293 SOCIETE IMMOBILIERE TOURMALINE INC.736859 SOGEFOR LTEE .SOGEFOR LTD.3726-63 STONECREST CONSTRUCTION LTD.330-68 STUDIO DE PHOTO QUEBECOIS INC.721492 TELE-CABLE VIDEOTRON LTEE.734665 THE TILDEN CORPORATION.1312-25 LA TRIBUNE LTEE.5282-66 TWINPAK LTD.10070-54 UNICORN FUEL OIL INC.LES CARBURANTS LICORNE INC.3836-69 UNITED TRUCK REPAIR INC.REPARATION DE CAMIONS UNIS INC.736822 VITA YOGURT PRODUCTS LIMITED.LES PRODUITS YOGOURT VITA LIMITEE 12022-51 VITA YOGURT PRODUCTS LIMITED.LES PRODUITS YOGOURT VITA LIMITEE 12022-51 VITA YOGURT PRODUCTS LIMITED.LES PRODUITS YOGOURT VITA LIMITEE 12022-61 YVETTE LEATHER CO.LTD.5585-65 06 03 67 3 4 19 11 71 9 12 29 01 73 4 7 05 10 71 3 7 18 04 73 3 4 30 08 63 9 5 23 01 68 5 3 16 03 72 3 5 24 10 73 5 6 16 07 25 5 3 21 12 66 7 4 18 01 54 6 7 07 08 69 3 4 13 04 73 4 3 11 09 51 3 6 11 09 51 6 7 11 09 61 7 10 20 12 65 3 4 57195-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57195-0 Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service. 3742 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol 106, No.SO Ventes par Shérifs Sheriffs Sales AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.DRUMMOND DRUMMOND No 405-02-000094 -7,{E Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District of Drummond EDGAR HAMEL, plombier, domicilié et résidant à St-¦ Germain de Grantham, district de Drummond.demandeur, vs PAUL BRULOT-TE, résidant à 474 Boul.Pie IX, St-N'icéphore, district de Drummond, défendeur.Un emplacement mesurant cinquante (50') pieds de largeur, par une profondeur de cent trente-six (136') pieds, le tout plus ou moins, mesure anglaise, connu et désigné au cadastre du Canton de Wickham.eommc étant la demie (} ; c) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-dix du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-70) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine.division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 75 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie :> ; d) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante et onze du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-71) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 85 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie » : e) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-douze du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-72) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de La-prairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 95 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie »; /) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro quarante du lot originaire numéro trois cent vingt et un 1,321-40) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 100 rue de la Lune, Laprairie »; g) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro cinquante-huit du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-58) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-dc-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 200 rue de la Lune, Laprairie » ; A) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-cinq du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-65) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 25 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie » ; i) « un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-six du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-66) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie.avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 35 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie » ; three hundred twenty-one (321-30) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 70 des-Champs Fleuris Boulevard, Laprairie\" ; (c) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventy of original lot number three hundred twenty-one 1.321-70) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 75 Des-Champs-Fleuris Boulevard, Laprairie\"; (d) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number seventy-one of original lot number three hundred twenty-one (321-71) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 85 Des-Champs-Fleuris Boulevard, Laprairie\"; (e) \"A certain emplacement known and described as being subdivision seventy-two of original lot number three hundred twenty-one (321-72) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 95 Des-Champs-Fleuris, Boulevard, Laprairie\"; (/) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number forty of original lot number three hundred twenty-one (321-40) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleinc, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 100 De-la-Lune Street, Laprairie\"; (g) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number fifty-eight of original lot number three hundred twenty-one (321-58) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 200 De-la-Lune Street, Laprairie\"; (h) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-five of original lot number three hundred twenty-one (321-65) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 25 Des-Champs-Fleuris Boulevard, Laprairie\"; (t) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-six of original lot number three hundred twenty-one (321-66) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 45 Des-Champs-Fleuris Boulevard, Laprairie\"; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3747 j) ' un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision numéro soixante-sept du lot originaire numéro trois cent vingt et un (321-67) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Laprairie-de-la-Magdeleine, division d'enregistrement de Laprairie, avec bâtisse y dessus en voie de construction portant le numéro civique 45 boulevard des Champs Fleuris, Laprairie » ; Pour être vendu séparément au bureau d'enregistrement du comté de Laprairie.à 214, St-Ignace, à Laprairie, P.Q., le VINGT ET UNIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 13 mai 1974.57301-o fj) \"A certain emplacement known and described as being subdivision number sixty-seven of original lot number three hundred twenty-one (321-67) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Laprairie-de-la-Magdeleine, Laprairie registration division, with a building thereon under construction bearing civic number 45 Des-Champs-Fleuris Boulevard, Laprairie\"; To be sold separately at the County of Laprairie registry office, 214 St.Ignace, Laprairie, P.Q., on the TWENTY-FIRST day of JUNE, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court.Assistant Sherif.Montreal, May 13, 1974.57301 Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal (Division de faillite) No 11-001173-73.( T\\ANS L'AFFAIRE DE LA 18-000 374-745X *-J FAILLITE DE: SOLANGE l BORDUAS.de Beloeil, district de Montréal, faillie, BANQUE D'EXPANSION INDUSTRIELLE, corps bancaire légalement constitué, ayant une place d'affaires au 800, Carré Victoria, suite 4600, Montréal, district de Montréal, requérante, r* J.-GUY ST-GEORGES, syndic à ladite faillite, faisant affaires au 401 est, boul.St-Joseph, Montréal, district de Montréal, intimé.« Cet immeuble, sis à l'angle du boulevard Laurier et de la rue Montenach, en la Ville de Beloeil, division d'enregistrement de Verchères, composé des lots de terre connus et désignés comme étant les subdivisions officielles numéros quarante-cinq, quarante-six et quarante sept, toutes du lot originaire numéro quarante et un (41-45, -46 et -47) au cadastre officiel de la paroisse de St-Mathieu de Beloeil, mais, a extraire desdits lots 41-45 et -46 la partie d'iceux, appartenant à la Voirie du Québec et telle que cette dite partie distraite est plus au long décrite aux termes de l'Acte de vente par Demoiselle Claire Dupré, et Dame Pierrette Dupré, épouse de Monsieur J.Berger, à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, aux droits de la Province de Québec (Ministère de la Voirie), passé devant Me Bernard Cormier, notaire, le quatorze décembre mil neuf cent soixante et un dont copie a été enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Verchères sous le numéro 71415, et mesurant la totalité de l'immeuble actuellement hypothéqué lequel est de forme trapézoïdale, quatre vingt seize pieds et quatre vingt dix huit centièmes de pied (96.98') dans sa limite sud-est ou en front sur ledit boulevard Laurier et quatre vingt quatorze pieds (94') de largeur dans sa limite nord-ouest sur une profondeur de cent trente deux pieds (132') dans sa limite nord-est ou en front sur ladite rue Montenach et de cent cinquante pieds et neuf dixièmes de pied (155.9') dans sa limite sud-ouest, et Toutes les dimensions ci-devant indiquées étant des mesures anglaises, et Canada \u2014 Province of Québec Superior Court ¦\u2014 District of Montreal (Bankruptcy Division) No.11-001173-73.1 TN THE MATTER OF THE 18-000 374 745X 1 BANKRUPTCY OF SOLAN-l GE BORDUAS of Beloeil District of Montreal bankrupt INDUSTRIAL EXPANSION BANK a banking corporation legally incorporated having a place of business at 800 Victoria Square Suite 4600 Montreal District of Montreal plaintiff versus J.-GUY ST-GEORGES trustee in said bank ruptcy carrying on business at 401 St.Joseph Boulevard East Montreal District of Montreal defendant.\"That immoveable situated at the intersection of Laurier Boulevard and Montenach Street in the Town of Beloeil Verchères Registration Division comprising the lots known and described as being official subdivisions numbers forty-five forty-six and forty-seven all parts of original lot number forty-one (41-45 -46 and -47) on the official cadastre for the Parish of St.Mathieu de Beloeil, but, to withdraw from said lots 41^45 and -46 that part thereof belonging to the Québec Roads Department, as (said withdrawn part is) more fully described according to the terms of the deed of sale by Miss Claire Dupré and Mrs Pierrette Dupré to Her Majesty Queen Elizabeth II in the rights of the Province of Québec (Roads Department) executed before Mc Bernard Cormier notary on December fourteenth one thousand nine hundred and sixty-one a copy of which deed has been registered at the Verchères Division Registry Office under number 71415; the whole of the immoveable presently mortgaged which is of trapezoidal configuration measuring ninety-six and ninety-eight hundreths feet (96.98') on its southeast limit or in front on said Laurier Boulevard and ninety-four feet (94') in width on its northwest limit by a depth of one hundred thirty-two feet (132') on its northeast limit or in front on said Montenach Street and one hundred fifty and nine tenths feet (155.9') on its southwest limit, All the above-mentioned dimensions being in English measure. 3748 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, Mi, Vol.106, No.SO Tel que le tout se trouve actuellement, avec toutes les constructions, circonstances et dépendantes, y érigées notamment une bâtisse, comportant trois (3) locaux commerciaux et deux (2) logements et portant les numéros 712, 714, 716, 718 et 720 dudit boulevard Laurier.Avec toutes les bâtisses et améliorations dessus érigées, en voie de construction ou à être érigées sur ledit immeuble et comprenant la machinerie, l'outillage, les agencements, engins, fournaises, bouilloires, moteurs et accessoires qui sont ou deviendront la propriété de l'emprunteur, et installés ou à être installés dans lesdites bâtisses ou sur ledit immeuble et qui sont ou deviendront immeubles par nature ou par destination.Tel que le tout se trouve actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées.Comprenant également, dans ladite vente en bloc: 1.une laveuse double Philco Bendix turquoise, No de modèle 9HDLK1, No de série 032520.2.une laveuse double Philco Bendix turquoise.No du modèle 9HDLK1, No de série 032518.3.une laveuse double Philco Bendix turquoise, No du modèle 9HKLK1, No de série 032526.4.une laveuse simple Philco Bendix jaune.No du modèle 7DL, No de série 16909.5.une laveuse simple Philco Bendix jaune.No du modèle 7DL, No de série 17007.6.une laveuse simple Philco Bendix jaune, No du modèle 7DL, No de série 16455.7.une laveuse simple Philco Bendix jaune, No du modèle 7DL, No de série 16450.8.une laveuse simple Philco Bendix jaune, No du modèle 7DL, No de série 16454.9.une laveuse simple Philco Bendix jaune, No du modèle 7DL, No de série 17001.10.une laveuse simple Philco Bendix jaune.No du modèle 7DL, No de série 16889.11.une laveuse simple Philco Bendix jaune, No du modèle 7DL, No de série 16464.12.une sécheuse double Guest Philco jaune.No du modèle 30/30, No de série TTC 158516.13.une sécheuse double Guest Philco jaune.No du modèle 30/30, no de série TTC 158517.14.une sécheuse double Guest Philco jaune, No du modèle 30/30, No de série TRC 158518.15.une sécheuse double Guest Philco jaune.No du modèle 30/30 No de série TTC 158519.16.un chauffe-eau.No du modèle HD 700-7-L.17.un track extracteur.No du modèle R-B-15.18.deux distributrices à savon.19.Machine électrique pour échanger la monnaie.No de série 159053.20.une essoreuse.No de série 26158P.21.une machine à liqueur.No de série OHF084947.22.distributrice de cigarettes.23.5 distributrices de peanuts, gommes.24.distributrices de verres.» As the whole now subsists with all constructions appurtenances and dependencies erected thereon namely a building comprising three (3) business premises and two (2) apartments bearing numbers 712, 714, 116, 718 and 720 on said Laurier Boulevard.With all buildings and improvements erected thereon under construction or to be erected on said immoveable and comprising the machinery equipment fittings and fixtures engines furnaces boilers motors and accessories which are or shall become the property of the borrower and installed or to be installed in said buildings or on said immoveable and which are or shall become immoveables by nature or by destination.As the whole now subsists with all active and passive apparent or nonapparent servitudes attaching thereto.Also comprising in said sale \"en bloc\" : 1.A turquoise Philco Bendix combination washer-dryer model No.9HDLK1 serial No.03^520.2.A turquoise Philco Bendix combination washer-dryer model No.9HDLK1 serial No.032518.3.A turquoise Philco Bendix combination washer-dryer model No.9HKLK1 serial No.032526.4.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL.serial No.16909.5.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.17007.6.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.16455.7.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.16450.8.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.16454.9.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.17001.10.A yellow Philco Bendix washer model No.7DL serial No.16889.11.A yellow Philco Bendix washer model No.7DI.serial No.16464.12.A yellow Guest Philco double-load dryer model No.30/30 serial No.TTC 158516.13.A yellow Guest Philco double-load drvcr model No.30/30 serial No.TTC 158517.14.A yellow Guest Philco double-load dryer model No.30/30 serial No.TRC 158518.15.A yellow (Juest Philco double-load dryer model No.30/30 serial No.TTC 158519.16.A water-heater model No.HD 700-7-L.17.A Track extractor model No.R-B-15.18.Two soap-distributors.19.An electric money-changer serial No.159053.20.A spin dryer serial No.26158P.21.A soft-drink-vending machine serial No.OHF-084947.22.A cigarette-vending machine.23.5 peanut and chewing-gum-vending machines.24.Glass vending machines.\" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n' SO 3749 Pour être vendu en bloc au bureau d'enregistrement de Verchères, à 613 Marie-Victorin, Verchères, P.Q.le DIX-NEUVIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 8 mai 1974.57300-c- Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A BANQUE D'EPARGNE No 05-013 398-73.< *-> DE LA CITE ET DU 'DISTRICT DE MONTREAL.corporation légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires et son siège social au 276, rue St-Jac-ues ouest, en les ville et district de Montréal, deman-eresse, versus CARMELO RIGANO, domicilié et résidant au 8162, Chamillv, St-Léonard, et al., défendeurs, et LE REGISTRATEUR de Montréal, mis en cause.« Ce certain emplacement connu comme étant le lot numéro vingt-huit de la subdivision numéro trois cent quatre-vingt-quatre (384-28) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Sault-au-Récollet, mesurant 42.0 pieds de largeur sur 107.7 pieds dans sa ligne sud-est et 107.5 pieds dans sa ligne nord-ouest, le tout en mesures anglaises, plus ou moins.Avec la bâtisse y dessus en voie de construction, partant les numéros civiques 8160 et 8162 de la rue Chamilly, dont le mur sud-ouest est mitoyen.Tel que ladite propriété se trouve présentement avec tous les droits, membres et circonstances, ainsi que toutes les servitudes actives et passives qui s'y rattachent.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice de Montréal, 10, rue Craig est, 10e étage, chambre 56, le VINGTIÈME jour de JUIN 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 7 mai, 1974.57279 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec à savoir: ( OCOTT AUTOMOBILES INC., Cour Provinciale J O corporation légalement consti-No 295-860.J tuée et ayant sa place d'affaires à ' Scott Jonction, comté de Dorchester, P.Q.vs ROBERT FERLAND, 25 Desroches Notre-Dame-des-Laurentides, ancienne adresse; Vil-lieux St-Nicolas, comté de Lévis.« Le lot 595-9-2 du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, de figure régulière: Bornée au nord-est et au sud-est par le lot 595-13, au sud-ouest par le lot 595-9-1 (rue), au nord-ouest par le lot 594 n.s.Mesurant au nord-est et au sud-ouest soixante-dix-neuf pieds et cinq dixièmes (79.5 pi.) soit 24.23 m, au sud-est et au To be sold \"en bloc\" at the Verchères Registry Office at 613 Marie-Victorin Verchères P.Q.on the NINETEENTH day of JUNE 1974 at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office Paul St-Martin Superior Court Assistant Sheriff.Montreal, May 8, 1974.57300 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montréal (THE MONTREAL CITY No.05-013 398-73.< A AND DISTRICT SAV- QUEBEC LTEE, corporation légale-' ment constituée ayant sa principale place d'affaires au 2, rue Main ouest à Coaticook, district de St-François, demanderesse, vs LEONARD JOHNSON et HILDA JOHNSON demeurant au 8, rue Central, Beebe, district de St-François.défendeurs.« Un immeuble connu et désigné comme étant: un immeuble sis et situé au village de Beebe, Que.connu et designé comme formant partie du lot numéro quarante-neuf (49) aux plan et livre de renvois officiels pour le village de Beebe Plains, mesurant une largeur uniforme de soixante pieds (60') mesure anglaise et plus ou moins, tel qu'acquis de la succession de John C.Hol-lard.aux termes d'un acte de vente exécuté sous seing privé le 8 juillet 1968 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Stanstead sous le numéro 86,884.avec la maison dessus érigée.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement à Stanstead Plain, P.Q., MARDI, le DIX-HUITIÈME jour de JUIN 1974, à DIX heures de la matinée.Bureau du Shérif, Palais de Justice, Le shérif adjoint.Sherbrocke, P.Q., Jean-Guy Bisson.Ce 6 mai 1974.57201-o TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Terrebonne ( p ARRIERE & LEFEBVRE INC., No 67,261 a >-ourg ouest (L').3573 Association du terrain de jeux des artisans de la baie St-Paul (L').3573 Astor Agencies Ltd.3573 Ateliers de soudure de Rimouski limitée (Les) 3573 Auberge de l'Etang inc.3573 Audio Communications Limited.3573 Automotive General Supplies Ltd.3573 B.C.Construction Inc.3573 Baby's Diaper Service Limited.3573 Baker Hotels Limited.3574 Baldwin's Storage Ltd.3574 Bambino Security Ltd.3574 Bauer International Investment & Securities Co.Ltd.3574 Bélanger (Marcel) cie ltée.3574 Benoit (Robert et Gérard) inc.3574 Bertrand (C.) inc.3574 Boulevard Restaurant inc.;.3574 Bourbeau Dufresne (J.) limitée.3574 Boutique de Monsieur Pierre inc.3574 Breuvages Jano inc.3574 Broadway Textile Processing Ltd.3574 Caplan (Dinah Lily) Social Service Group.3574 Carrière Deschambault inc.(La).3574 Carrières Martineau et Deschambault inc (Les).3574 3764 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.SO Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Chenoy Boys Delicatessen Ltd.3574 Cie Jarry-Fabre ltée (La).3574 Club de C.& P.S.L.C.Pointe Jaune.3574 Club de croquet Le Trois-Rivières inc.(Le) 3574 Club Dice-.3574 Club Papineau incorporé (Le).3574 Club des professionnels du Québec inc.(Le) 3574 Club Richelieu Ste-Rose-de-Laval inc.3574 Club des sportifs d'Alraa inc.(Le).3574 Clubs juvéniles de la cité Jacques-Cartier inc.(Les).3575 Colonial Chrome Company Limited.3575 Comité d'entretien aes chemins d'hiver de St-Zénon.3575 Compagnie d'immeubles de Montréal (La).3575 Compagnie de placements des Milles Isles limitée.- 3575 Compagnie de publication « L'Economie rurale » inc.(La).3575 Conseil d'habitation économique Beaufort ltée Consolidated Dolsan Mines Ltd.3575 Continuous Forms (Québec) Limited.3575 Corporation des chemins d'hiver d'Abitibi- est.3575 D.C.Couvertures inc.3575 D.F.N.Wood Products Limited.3575 D.P.Lumber Corporation.3575 Daisy Development Corp.3575 Dalac Mines Limited.3575 Dalbross Construction limitée.3575 D'Amour inc.3575 Dauphin Inc.3575 Dave's Market Inc.3575 De La Salle Chesterfield Inc.3575 Decarie Boulevard Land Development Co.Ltd.3575 Deckelbaum (Hy) Ltd.3575 Del Monte Studio Inc.3575 Delson Lumber Incorporated.3576 Demers & Cie inc.3576 Dénommée (D.) & Company Limited.3576 Denys (T.N.) & Cie limitée.3576 Derice (Leanora) Inc.3576 Dermer Mfg.Inc.3576 Deschamps & Bélanger ltée.3576 Desfossés & Frères ltée.3576 Desmarais & Pelletier inc.3576 Deux-Montagnes Drive Yourself Inc.3576 Devon Society, Inc.3576 Diana Restaurant Inc.3576 Diana Shoe Company Limited.3576 Dickman & Dickman Inc.3576 Dion (A.) & Fils inc.3576 Distributeurs Plateau ltée.3576 Distributors Incorporated.3576 Doctor X Preparations Ltd.3576 Domaine Des Pins ltée.3576 Domestic Heating Incorporation.3576 Dominion Concerts Inc.3576 Dominion Dress Limited.3576 Dominion Electric Contractors Co.3576 Draperies Québec inc.3576 Dubuc (Maurice) ltée.3576 Eastern Television Import Co.Ltd.3577 Eclair Electrique ltée (L').3577 Ecole provinciale des maîtres-nageurs inc.3577 Excel Garment Inc.3577 Foreign Trades Bureau Incorporated.3577 G.A.Aluminium inc.3577 Garage Belley limitée.3577 Gaspé Service Station Ltd.3577 Gaz médical P.A.ltée.3577 Gem Motor Sales Limited.3577 Genest (A.) ltée.3577 Gestion modulaire inc.3577 Naycock Realties Inc.3577 Hôtelleries Faucher inc.3577 Huron Fishing Tackle Inc.3577 Hygrade Fur Co.3577 Immeubles Poulin Realties Ltd.(Les).3577 Imprimerie Crémazie ltée.3577 Independent Refrigeration Limited.3577 Indoor Games Limited.3577 Industrial Appliances Corporation.3577 Industrial Appliances Ltd.3577 Institute of Radio and Television.3577 Italo Canadian Club of Rouyn-Noranda Inc.3577 J.B.Ski Club Inc.3577 Jardin royal ltée.3578 Jedo Belts Ltd.3578 Joliette Pants & Sportswear Ltd.3578 Joy Frocks Inc.3578 Julmor Ltd.3578 Kaemes Construction Co.Ltd.3578 Kill-Odor Products Inc.3578 Kinsmen Club of Lachine-Dorval Inc.(The).3578 Kirk Trading Corporation.3578 Kirkor Investment Corp.3578 Kleinert Company Limited.3578 Lad and Lassie Nursery and Kindergarten Inc.3578 Laforest (Nap.) & Fils limitée.3578 Laiterie Granger Frères, ltée (La).3578 Laiterie Mile End limitée.3578 Laiterie Rouen Inc.3578 Lajeuenesse (W.) & Cie limitée.3578 Lakeshore Industries Inc.3578 Lamontagne (Léandre) limitée.3578 Lamont's Men's Wear Limited.3578 LaSalle Finance Corporation Ltd.3578 Lawrence (Steve) Inc.3578 Leclair Frozen Egg Products Inc.3578 Lessard (Rudy) inc.3578 Ligue anti-pollution League Inc.3578 Ligue des citoyens de St-Marc-des-Carrières inc.(La).3579 Ligue des citoyens de Saint-Thomas-d'Aquin de Ste-Foy inc.(La).3579 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n° 20 3765 Ame de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (mite) (continued) Ligue de hockey junior « B » de la cité de Rivière-du-Loup (La).3579 Ligue des propriétaires de St-Simon de Drummond (La).3589 Logement de Hull limitée.3579 Loisirs d'Arthabaska inc.3579 Louanda Realties Inc.3579 Lucky Star Realties Inc.3579 Majestic Enterprises Inc.3579 Mandarin Gardens Inc.3579 Manufacture de manches Boisvert & Cie ltée (La).3579 Marchand (P.) limitée.3579 Marina Cold Storage Co.Ltd.3579 Marquis Junior B inc.(Les).3579 Martin Realties Inc.3579 Maw Brothers Limited.3579 Megantic Auto Inc.3579 Merchants Housing Company Ltd.3579 Mergl et Fils Compagnie limitée.3579 Metallics & Plastics Limited.3579 Metallurg (Canada) Ltd.3579 Métropole Moulding Co.Ltd.3579 Meubles Antoine inc.3579 Meubles B.N.L.inc.3580 Miller (R.) & Sons Transport, Inc.3580 Miss Poole, Inc.3580 Mitch's Sportswear Inc.3580 Mitrolac Manufacturing Ltd.3580 Mittex Ltd.3580 Mollo Restaurants Ltd.3580 Montreal Factors Corporation Ltd.3580 Montreal Precision Works Ltd.3580 Nadeau (Alfred) inc.3580 Noël (L.W.) (Québec) limitée.3580 North Star Construction Ltd.3580 North-American Jewellery Stylers Inc.3580 Northern Equipment & Auto Parts Co.Ltd.3580 Nouveau Cinéma Rosemont Inc.3580 Nylon Centre Ltd.3580 Oditan Mines Limited.3580 Oeuvre des loisirs de Ste-Marguerite inc.(L') 3580 Oeuvre des terrains de jeux de St-Alexis, inc.(L').3580 Page (Guy) auto inc.3580 Phélan, Destrempes & Reynolds Limited- 3580 Philie-Charonnat Entreprises ltée.3580 Phoenix Studios Inc.3580 Placements Colbert inc.(Les).3580 Placements Port Cartier inc.3580 Placements Vicalco inc.3581 Plating Industries Limited.3581 Plourde & Plourde limitée.3581 Plymouth Laboratories Inc.3581 Popeye's Snack Bar Incorporated.3581 Posidon Restaurant Inc.3581 Pouliot (D.I.), ltée.3581 Premier Brand Clothing Co.Ltd.3581 Princess Silks Inc.3581 Princeton Sportswear Inc.3581 Products and Services Limited.3581 Produits artistiques limitée (Les).3581 Prospectors and Miners Club (The).3581 Publications M.B.C.inc.(Les).3581 Publicité B.& S.Publicity Limitée.3581 Québec Broom & Mop Manufacturers Association Incorporated.3581 Québec Butchers Supply inc.3581 Québec Charity Trust Found of the Army, Navy and Air Force Veterans Incorporated - Québec Unit No.33 (The).3581 Québec Diocesan (Church of England) Council for Social Service (The).3581 Québec Fibre Company, Limited.3581 Québec Fish Breeders Ltd.3581 Québec Highway & Excavation Ltd.3581 Québec Holdings Corporation.3581 Québec Interlocking Cement Products Limited 3582 Québec Iron Mining Company.3582 Québec Velodrome Inc.3582 Québec Waterways Sightseeing Tours Company .3582 Quong Yick Recreation Club Inc.3582 R.J.Stamping Co.Ltd.3582 Rack Industries of Canada Ltd.3582 Radar Corporation Limited.3582 Ransom Inc.3582 Rapid Press Limited.3582 Rapid Transport Terminal Limited.3582 Rigaud-Construction, limitée.3582 Roch Auto ltée.3582 Rousseau & Baillargeon limitée.3582 Rubvlee Inc.3582 S.& A.Motors Inc.3582 St-Vallier Automobiles Inc.3582 Samson (J.E.), incorporée.3582 Santé Nationale, incorporée (La).3582 Sauriol Construction Co.Ltd.3582 Sauriol (H.) ltée.3582 Savard (Margot) inc.3582 Saxe Brothers Inc.3582 Segal (WM.) Inc.3582 Segatore (C.) Bakery Limited.3583 Seguin Consolidated Mines Limited.3583 Select Chemical Corporation.3583 Select Chemical and Soaps Inc.3583 Select Construction Co.Ltd.3583 Service Economique ltée (Le).3583 Service Fur Co.Ltd.3583 Service industriel Service Inc.3583 Seventy Seventy-One St.Urbain Ltd.3583 Shannon Shoe Fitting Company Limited.3583 Sharon Dress Manufacturing Inc.3583 Shawinigan Mining and Smelting Company Limited (The).3583 Simard (Adjutor) inc.3583 Singer (Philip A.), Ltd.3583 Sirois limitée.3583 3766 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Sladen (Québec) Limited.3583 Sleepy Giant Mines Limited.3583 Slip-On Footwear Co.Limited (The).3583 Sloppy Joe's Steak House Inc.3583 Smart Maid Dress Inc.3583 Smith Floral Shoppe Inc.3583 Smith (Julian C.) Memorial Fund Corporation (The).3583 Société d'administration de la maison des oeuvres (La).3583 Société d'aide à la jeunesse de Ayers Cliff 3583 Société des arts de Québec (La).3584 Société d'assistance aux immigrants.3584 Société du bon parler français de la Mauricie (La).3784 Société Colbert, limitée.3584 Société éducationnelle incorporée.3584 Société d'optométrie de Montréal incorporée (La).3584 Société de pédiatrie de Montréal incorporée (La).3584 Société de placements immobiliers de Granby inc.(La).3584 Société de protection Notre-Dame (La).3584 Société St-Jean-Baptiste de Kénogami, P.Q.(La).3584 Société des spectacles incorporée (La).3584 Société sportive de Matane inc.(La).3584 Sonny Sobel Sales Ltd.3584 Sorel Transport limitée.3584 Sorensen (C.) & Son Ltd.3584 Soroka Inc.3584 Soucie (L.), limitée.3584 South Shore Forest Products Co.Ltd.3584 Spar-Mica Corporation Ltd.3584 Specialty Supply Service of Canada Limited.3584 Sport illustré inc.3584 Sport et loisirs ltée.3584 Sports & Leather Products Ltd.3584 Standard Hotel & Hospital Supplies Inc.3584 Stanley Drive Yourself System Inc.3585 Sterling Teas & Coffees Limited.3585 Storey Retirement Nursing Homes.3585 Successors to the Swif t-CopIan Building Ltd.3585 Système économique des consommateurs ltée.3585 Téléphone de St-Honoré de Shenley inc.3585 Télévision Mart inc.3585 Tobiash (H.T.) Ltd.3585 Tondi (Louis), Inc.3585 Triangle Realty Corporation.3585 United Resources Inc.3585 Viking Inc.(The).3585 Wilshire Florists Inc.3585 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: Acme Pad Co.Ltd.3585 Agence A.B.autoneige & sport ltée.3585 Ahuntsic Transport Ltd.3585 Ajustement Laval ltée.3585 Albert Novelty Co.3585 Almar Chocolates Ltd.3585 Amicale franco-canadienne (L').3585 Amos Automobile Accomodation Inc.3585 Anciens combattants (Québec) inc.(Les).3586 Andal Laboratories Limited.3586 Aqua Revue ltée.3586 Artisans d'Argenteuil inc.(Les).3586 Ascot Leather Goods Ltd.3586 Association des anciens de Rouyn-Noranda inc.(L').3586 Association des cabarets et hôtels de la province de Québec.3586 Association de hockey de Plessisville inc.3586 Association des jeunes scientifiques.3586 Association des parents d'étudiantes du collège Sophie-Barat.3586 Ateliers d'art liturgique ltée (Les).3586 Au Sablonnet de Jonquière ltée.3586 Au Tison d'Or inc.3586 Austin Youth Association Inc.(The).3586 Autobus métropolitain ltée.3586 B.S.G.International Enterprises Ltd.3586 Beauharnois Transit Inc.3586 Bélair automobile limitée.3586 Belcourt Gold Mines Limited.3586 Béliveau Manufacturing Ltd.3586 Belle-Aura Mines Limited.3586 Belley (J.C.) limitée.3586 Belmont Sportswear Co.3586 Benedicts Club Incorporated.3586 Berger & Chachter Company Limited.3586 Berger (M.) & Sons Limited.3586 Bergeron Electronic Inc.3586 Bergeron & Potel limitée.3586 Bergerville Wood Industries Inc.3586 Bergs (St.Jérôme) Inc.3586 Bernier (J.Alphonse) limitée.3586 Best Ever Dress Co.Ltd.3586 Best Lumber Co.3586 Bethlehem Co.(The).3586 Better Homes Builders Limited.3586 Better Seats Co.3586 Betty Belle Ltd.3587 Betty & Maxime Sportswear Limited.3587 Bien-Etre social de Québec (Le).3587 Bien-Etre social de St-Joseph d'Alma (Le).3587 Bienvenue Transport inc.3587 Bijouterie Marko inc.3587 Bilodeau (J.A.) limitée.3587 Bilodeau limitée.3587 Binette (CE.) ltée.3587 Birdee Togs Inc.3587 Biron-Knitting Mills Ltd.3587 Bishop Holdings Limited.3587 Bist (George) Limited.3587 Biais & Cie ltée.3587 Blanchet & Dallaire limitée.3587 Bley Embroidery Inc.3587 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106' année, n° SO 3767 Lettres patentes annulées: letters Patent Annulled: (.suite) (continued) Blomindon Holdings Limited.3587 Blousecraft Incorporated.3587 Blue Bird Shoe Ltd.3587 Board of Trade of the Municipality of Mann.3587 Boileau (Ulric) & Fils limitée.3587 Bois Supérieur limitée.3587 Boisclair & Dragon Limited.3587 Botte de fantaisie limitée (La).3587 Boivin (J.Alphonse) & Company limitée.3587 Boivin (Marcel) & Compagnie ltée.3587 Boivin Transport inc.3587 Bonne Fourchette inc.(La).3587 Bonneau automobile inc.3587 Bonnie Burn Camp Ltd.3587 Bordeleau Electrical Supplies Ltd.3587 Boris Fashions Inc.3587 Borts (Maurice) Inc.3587 Bouchard & Cie (limitée).3587 Bouchard (D.) limitée.3587 Bouchard transport limitée.3587 Bouchers-épiciers associés limitée (Les).3587 Bouffard (Gérard) limitée.3588 Bouffard (S.) ltée.3588 Bougie & Frères limitée.3588 Boulangerie Lachute ltée.3588 Boulangerie royale Bakery incorporée.3588 Boulianne (H.) limitée.3588 Bourcier Motor Sales Inc.3588 Bourgeois & Bourgeois, limitée.3588 Boutique du cadeau de l'hôpital Jean-Talon inc.(La).3588 Boutique El Paso inc.(La).3588 Boyscraft Limited.3588 Boyston Shirt Mfg.Co.Ltd.3588 Bradley (H.E.) Coal Corporation.3588 Braemore Apartment Company.3588 Braislnc.3588 Bram Fur Co.Ltd.3588 Brault (J.D.) limitée.3588 Brault (J.L.) limitée.3588 Brault (J.P.) limitée.3588 Bridal Gowns Inc.3588 Bridgewater Lumber Company Limited.3588 Brière & Bisson limitée.3588 British Canadian Investment Corporation.3588 British Loomcraft (Canada) Ltd.3588 British Textiles Limited.3588 Brock (Samuel) & Sons Inc.3588 Brookside Investments Ltd.3588 Brotherhod & Sisterhood of Temple Salomon Free Loan Association.3588 Brouillet Sand & Gravel Company Limited.3588 Browman Realty Inc.3588 Brown-Bousquet Mines, Limited.3588 Bruce (J.A.) & Co.Limited.3588 Brunet & Mitchell ltée.3588 George M.Brunton Construction Company Limited (The).3588 Bruun (Alex) Limited.3588 Bru wood Inc.3588 Buanderie Federal Laundry Ltd.3588 Buanderie des Laurentides limitée.3589 Buanderie St-Laurent inc.(La).3589 Bûche L'Islet, limitée.3589 Buckingham Mining Corporation.3589 Budget Factors Ltd.3589 Bureau de coordination du taxi.3589 Burge Lake Goldfields Limited.3589 Burns (John) & Company Limited.3589 Bussières & Frères ltée.3589 Button Industries Limited.3589 Byrd Brothers Ltd.3589 CM.and T.Incorporated.3589 Cache d'Or Gold Mines (Québec) Limited.3589 Caddie ltée.3589 Cadets de Grand'Mère (Les).3589 Cadres L'Eclair ltée (Les).3589 Café Le Chante Clerc Inc.3589 Café Lido limitée.3589 Café and Restaurant Holders Association of the Province of Québec.3589 Café St-Michel ltée.3589 Café Video Corp.3589 Caldwell Fruit Co.Ltd.3589 California Knitwear Ltd.3589 Cambridge Tailors Limited.3589 Cameo Sportswear Ltd.3589 Cameo Theatre Inc.3589 Canada Peat Limited.3589 Canadiennes Palettes ltée.3589 Carlton Upholstering Co.3589 Cartier Estate Corporation.3589 Centre des loisirs de Cap-des-Rosiers inc.(Le) 3589 Centre de loisirs de St-Paul.3589 Chagon & Cournoyer.3589 Chambre de commerce de St-Godefroy (La).3589 Champlain Sports Inc.3589 Château Mines Limited.3589 Cie de bois de Ste-Félicité ltée (La).3590 Cie de construction Elite limitée.3590 Cie de liqueurs Corona limitée (La).3590 Cie des tabacs Jaune-Clair de Joliette ltée (La).3590 Citadel Investment Corporation.3590 City Motors Ltd.3590 Claire-Anne Dress Co.Ltd.3590 Classy of Canada Limited.3590 Cloras Construction Inc.3590 Club d'aviation Sherbrooke inc.3590 Club Canada, limitée (Le).3590 Club « 200 ».3590 Club de golf de la Baie des Chaleurs inc.(Le).3590 Club de golf de St-Boniface.3590 Club optimiste métropolitain-haut d'Anjou inc.3590 Club optimiste Repentigny inc.3590 Club raquetteur L'Algonquin (Le).3590 Club de St-Emile inc.3590 Club social des capilliculteurs du Canada.3590 3768 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 197j, Vol.106, No.20 Lettres patentes annulées: (suite) Letters Patent Annulled: (continued) Club social et sportif du lac Aylmcr inc.3590 Club sportif de Daveluyville inc.(Lc).3590 Club sportif Ruisseau Rouge inc.3590 Club de tennis du moulin inc.(Le).3590 Coleraine Asbestos Limited.3590 Comité Chemin d'hiver de Ste-Julie de St- Guillaume.3590 Comité des chemins d'hiver de Nicolet (Le).3590 Comité des chemins d'hiver de St- Bona venture limitée.3590 Comité des chemins d'hiver de St-Denis-sur- Richelieu inc.(Le).3590 Comité des chemins d'hiver de St-Ours incorporé (Le).3590 Comité des chemins d'hiver de St-Zéphirin- de-Courval incorporé (Le).3590 Comité de citoyens de Laterrière inc.(Le).3590 Comité de développement de Cabano.3590 Comité d'entretien des chemins d'hiver de St- Bruno, Comté de Kamouraska.3590 Comité des loisirs Ste-Cécile.3590 Comité des loisirs de Ste-Marie-Salomé.3590 Comité des loisirs de Val St-Pierre (Le).3591 Comité du monument de la Dauversière.3591 Commercial Enterprises Inc.3591 Commercial Optical Company Limited.3591 Commercial Radio Laboratories Limited.3591 Commodities Incorporated.3591 Commonwealth Color and Chemical Co.Limited .3591 Compagnie Bélisle & Allard limitée.3591 Compagnie de biscuits Aetna limitée.3591 Compagnie de bois Brisson, ltée.3591 Compagnie de conserves de Napierville, limitée (La).3591 Compagnie de construction Bouchard et Rouleau (La).3591 Compagnie de construction de St-Guillaume ltée (La).3591 Compagnie de construction Senncvillc & St-André ltée (La).3591 Compagnie des grands spectacles inc.(La).3591 Compagnie de publication Le Flambeau inc.(La).3591 Compagnie de téléphone local de Stratford (La).3591 Compagnons de l'Art (Les).3591 Comptoir des marchands inc.3591 Comptoirs Grenier inc.(Les).3591 Comptoirs-Unis du Québec, incorporé.3591 Con-Air-Con Limited.3591 Concrète WaterProofing and Restoration Limited.3591 Confederation Realties Incorporated.3591 Congress Import & Novelty Inc.3591 Conserverie de Charlesbourg ltée (La).3591 Consolidated Sales Corporation.3591 Consolited Fur Inc.3591 Constantineau, Pelletier et Wilson, limitée.3591 Construction de Lévis limitée (La).3591 Construction préfabriquée limitée.3591 Consumers Industrial Minerals, Limited 3591 Consumers Products Corp.3591 Continental Enterprises Ltd.3591 Continental Laboratories Inc.3591 Continental Metals Corporation.3591 Contractors Uniform Company Limited.3591 Convoy Silks Ltd.3592 Cool (Emile) & Fils limitée.3592 Cooper-Hirsh Inc.3592 Corona Hosiery Corporation.3592 Coronet Gold Mine Limited.3592 Coronet Handbags Inc.\"3?Corporation des grossistes de Chicoutimi(La) 3592 Corporation de l'institut du radium de l'Université de Montréal et de la province de de Québec.3592 Corporation des propriétaires du lac des Sept-Iles (La).3592 Corporation de protection de documents (La) 3592 Corporation récréative d'Outremont.3592 Corporation Services Ltd.3592 Corps de tambours et clairons Les Marquises inc.3592 Cosafiltée.3592 Cosmo Jewellery & Novelty Co.3592 Côté (C.) limitée.3592 Côté & Fils automobile limitée.3592 Côté (Gérard) automobiles inc.3592 Côté (Phil) Lumber Limited.3592 Côté Shoe Limited.3592 Cotton Motor Sales Co.Ltd.3592 Couillard (Arthur) ltée.3592 Coulombe (J.A.) & Co.Limited.3592 Country Housing Company.3592 Courageous Holdings Limited.3592 Courville & Desparois ltée.3592 Couvrette & Casoni inc.3592 Crabtree Plastics Limited.3592 Craftmills Novelties Limited.3592 Craftworks Trading Corp.3592 Craven Clothes & Sportswear Inc.3592 Creative Associates Inc.3592 Crédit industriel inc.3592 Crédit social du Québec (Le).3592 Crémerie Marieville limitée.3592 Crémerie Notre-Dame, limitée.3592 Cuirs Ternis limitée (Les).3592 Custom Shop Inc.(The).3593 Cycles Gachon incorporée.3593 Daisy Dee Cleaners Inc.3593 Dan Automatic Alarm Inc.3593 Del-Cat Corporation Ltd.3593 Diamond Steer Ltd.(The).3593 Dorsey-Picard Inc.3593 Dorval (Roméo) limitée.3593 Dozois (Paul) ltée.3593 Dress Contractors Association.3593 Drummondville Athletic Association Inc.3593 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- année, n' SO 3769 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: {suite) (continued) Dubé & Ducharme limitée.3593 Ducas Bros.Furriers Inc.3593 Duchaine (Ludger) inc.3593 Duchesne & Bouchard limitée.3593 Dugay Frères ltée.3593 Eastman Harwood Lumber Company Limited 3593 Ebénisteries Longueuil limitée (Les).3593 Econo limitée.3593 Edgewater Beach Hotel Inc.3593 Edibec Inc.3593 Edifice Godin ltée.3693 Edition La Victoire ltée (L').3593 Editions du Mercredi inc.(Les).3593 Ek-Ce-Lan Sports Inc.3593 Electromatic Engineering Co.Limited.3593 Encore-Meat Products Ltd.3593 Entreprises centrales inc.(Les).3593 Entreprises J.R.Legault ltée (Les).3593 Entreprises Jeanne d'Arc ltée (Les).3593 Entreprises Larela inc.(Us).3593 Entreprises Participex inc.(Les).3593 Erections de charpentes Dubois inc.(Les) 3593 Exuma Limited.3593 Faromale Inc.3593 Felici-Perrera Imports Inc.3593 Fite Rite Tailors Inc.3593 Flor-Nor Explorations Ltd.3594 Foma Manufacturers and Agents Limited .3594 Fondexltée.3594 Form Fit Shoulder Pad Ltd.3594 Foster Construction Inc.3594 Foyer de la gaieté de Chicoutimi-Nord.3594 Gaco Inc.3594 Gagnon (Zcël) limitée.3594 Garage La Patrie incorporée.3594 Gaymont (International) Limited.3594 General Notions Inc.3594 Gibson (Samuel) Inc.3594 Glenview Fruit Company.3594 Global Camping & Parking Inc.3594 Glory Shirt Mfg.Co.Ltd.3594 Golden Phoenix Restaurant Ltd.(The).3594 Grad Garment Limited.3594 Granby General Store Ltd.3594 Grawmont Mines Limited.3594 Grimmer Services (Limited).3594 Grondin & Savary Limited.3594 Guignion Bros.Ltd.3594 Guilde des régrattiers du Québec (Le).3594 Halpenny Limited.3594 Harmonie Cadette de Sherbrooke (L').3594 Hart Motors (Cartierville) Limited.3594 Hemisphere Trading Corp.3594 Henrico Construction Corporation.3594 Hiltoy Company Inc.3594 Hogg (T.F.) & Co.Ltd.3594 Hôtel Stanbridge inc.3594 Hôtel Victoria (Trois-Pistoles) inc.3594 Hull Concrete Products Limited.3594 Huron Fur Dressers Limited.3594 I.B.I.Systems Inc.3594 Immeubles Routexpress inc.(Les).3594 Imprimerie-lithographie Chartrand ltée.3594 Indian Lacrosse Club Ltd.3595 Industries du bois inc.(Les).3595 Industries métallurgiques de Roxton limitée .3595 Industries Ouellet ltée (Les).3595 Infatigable (L').3595 Institut de danse des Bois Francs inc.3595 J.G.automobile ltée.3595 Jeune Chambre de LaPrairie inc.(La).3595 Joints industriels métropolitains ltée (Les).3595 Journaux associés S.F.inc.(Les).3595 Junior Maid lingerie Mfg.Ltd.3595 La Commerciale (incorporée).3595 Laboratoire Algerine limitée.3595 Laboratoires Bio-Bacto ltée (Les).3595 Lac Masson Gold and Country Club, Inc.3595 Lacombe (J.C.) inc.3595 Lady Stella of Fifth Avenue Ltd.3595 Lajeunesse (J.P.) inc.3595 Lake St.John and Chibougamau Transport Limited.3595 Lakeside Homes Inc.3595 Langelier (P.A.) limitée.3595 Larofor Inc.3595 Laurier Rembourrage inc.3595 Lavage de vitres Campeau Window Cleaning Inc.3595 Lazarus (S.N.) & Co.Ltd.3595 Lemoine Chicougamau Mining Corporation.3595 Lépine (Adélard & Gustave), inc.3595 Lewis (Jack) Inc.3595 Liaison inc.3595 Librairie Vachon limitée.3595 Lido Products Company Limited.3595 Ligue d'avancement civique (La).3595 Ligue indépendante catholique de Montréal.3595 Ligue panaméricaine du Canada (Québec) (La).3595 Ligue pour la sauvegarde de l'industrie libre (La).3595 Ligue des propriétaires de Granby inc.(La).3595 Ligue des propriétaires des Trois-Rivières, inc.(La).3596 Ligue régionale de balle molle senior de la Rive Sud inc.3596 Like-Nu Fur Blending & Dyeins Ltd.3596 Limoges, Piché, Alarie ltée.3596 Limoilou électrique limitée.3596 Linda Manufacturing Inc.3596 Lingerie « Du Jour » inc.3596 Lingerie Sales Incorporated.3596 Linko Investment Ltd.3596 Lipari (Jos.) limitée.3596 Lipson (S.) & Co.3596 Little Cutie Inc.(The).3596 Little Theatre of Québec, Incorporated (The) 3596 Local Salvage Corporation.3596 Lodz Association.3596 3770 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, May 18, 1974, Vol.106, No.20 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Loisirs Notre-Dame.3596 Loisirs de St-Philémon inc.(Les).3696 M.G.communications visuelles inc.3596 Macleay (R.) & Company Limited.3596 Main Hebrew Delicatessen Inc.3596 Maison Routhier inc.(La).3596 Mamie Mines Limited.3596 Marchand Cyclo Massage de Québec inc .3596 Marché Jarry inc.3596 Mark (Pete) Inc.3596 Martin Engineering Incorporated.3596 Mason (Penny) (Canada) Ltd.3596 Maziade (Philippe) ltée.3596 Métro Excavation (1966) limitée.3596 Mets de Lachine inc.3596 Meubles & quincaillerie Beauchamp & Frères inc.'.3596 Mil-Boy Limited.3596 Minolet Brands Inc.3596 Minville (Geo.) & Associés ltée.3596 Modem Fashion Limited.3596 Modernfold (Cantons de l'Est) ltée.3596 Monalea Beach Bungalows Inc.3596 Monica Distributors Inc.3597 Montreal Terrazo Tile & Marble Limited .3597 Montreal Tile Terrazzo and Marble Employers' Association.3597 Monty & Frères ltée.3597 Motel La Bourgade inc.3597 Multi-Distribution Inc.3597 Nansu Management Corp.3597 Narimac limitée.3597 Nataki Corporation.3597 Neuvico ltée.3597 New York Garment Inc.3597 Nick's Discount Department Store Ltd.3597 Northamerican Casing Corporation.3597 Northern Resorts Association of the Lauren- tians.3597 Northern Sales Company.3597 Northern Tank Haulers Ltd.3597 Northern Timber Company Limited.3597 Northmount Sales Ltd.3597 Norwegian Woodcraft Limited.3597 Nouvelle organisation en construction inc.3597 Nova Knitting Limited.3597 Nova Realties Inc.3597 Nova Scotia Coal Sales Ltd.3597 Novamines Corporation.3597 Novelty Fabrics Inc.3597 Novelty Handbags Limited.3597 Novelty Mfg.Co.Ltd.3597 Novo Broom & Mop Supplies Corporation .3597 Nu-Mode Novelty Inc.3597 Nun's Island Theatre Inc.3597 Nu-Style Clothing Co.3597 Nu-Tone Products Limited.3597 Nu-Way Food Products Incorporated.3597 Nu-Way Meat Market Ltd.-.- 3597 Oeuvre des loisirs de la cité de Chicoutimi (L') 3597 Oeuvre du service familial (L').3597 Oeuvre des terrains de jeu de St-Jean-Port- Joli incorporée (L').3597 Oeuvre des terrains de jeux d'Armagh (L') .3598 Oeuvre des terrains de jeux de la Chambre de Commerce d'Iberville incorporée.3598 Oeuvre des terrains de jeux et colonies de vacances d'Arvida (L').3598 Oeuvre des terrains de jeux et d'embellissement de Bagotville (L').3598 Oeuvre des terrains de jeux de Montmagny inc.(L').3598 Oeuvre des terrains de jeux Saint Jean Bosco (O.T.J.de Joliette) (L').3598 Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Laurent (L').3598 Office Sales & Services Co.Ltd.3598 Oka Wood Products Limited.359S Onagon Investments Limited.3598 Onvx & Metal Products Limited (The).3598 Optimist Club of Verdun Inc.(The).3598 Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal.3598 Order Sons of Italy Building Association Incorporated .3598 Ore Monte Mine Inc.3598 Oremar Gold Mines Limited.3598 Orford Mining Company Limited.3598 Orgues O.Jacques (limitée).3598 Original Knish Bakery Ltd.3598 Orland Gold Mines (Québec) Limited.3598 Osisko Lumber Ltd.3598 Ottman Gold Mines Ltd.3598 Ouellctte Glove Works Ltd.3598 Outremont Curling Club Incorporated (The).3598 Overburden Drilling Company Limited.3598 Overseas Aid Association, Inc.(The).3598 Oxford Club (The).3598 P.A.T.Chemicals Limited.3598 P.& P.Manufacturing Co.Ltd.3598 Page (Edouard) limitée.3598 Page & Page ltée.3598 Palais sohmer limitée.3598 Palm Club Inc.3598 Palmer Realties Incorporated.3598 Palmers Salon Ltd.3598 Pam Trading Limited.3599 Pan Construction Inc.3599 Pan Investment Limited.3599 Pan-American Importers & Exporters Inc.3599 Papineau Holding Corporation.3599 Paquet (Jos.) limitée.3599 Paradis automobile ltée.3599 Paradis & Farley Inc.3599 Paramount Club Incorporated.3599 Paramount Club Incorporated.3599 Paramount Footwear Limited.3599 Paramount Leather Goods Co.Inc.3599 Paramount Service Enterprises Ltd.3599 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 1974, 106- aimée, n° SO 3771 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) ^continued) Paramount Trading Corporation.3599 Paraplastics Ltd.3599 Parfumerie Longchamps Ltd.3599 Paris Fur Co.Inc.3599 Paris Labo limitée.3599 Parizeau (Lucien) & Cie ltée.3599 Parfumerie L.T.Pi ver limitée.3599 Park Lane Gowns Inc.3599 Park Toboggan & Ski Club Limited.3599 Parktown Mfg.Ltd.3599 Parkway automobiles Limited.3599 Pastel Garment Manufacturing Company Ltd.3599 Pat-Ann Juniors Inc.3599 Patenaude (A.W.) incorporée.3599 Patricia Apartments Inc.3599 Patronage de Jonquière (Le).3599 Pavillon des Pointes Beaudet ltée (Le).3599 Pear-Lit Malartic Mines Ltd.3599 Peco Dyeing Inc.3599 Peerless Candies Ltd.3599 Peerless Furniture Manufacturing Co.Ltd.3599 Peggy Ann Shops Incorporated.3599 Peintures Idéales inc.(Les).3599 Pelchat-Gauthier limitée.3599 Pelletier & Co.Inc.3600 Pennsylvania Anthracite Company Limited.3500 People's 5f
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.