Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 8 (no 23)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-06-08, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" GAZETTE QUÉBEC V OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES PART 1 JURIDICAL NOTICES A ties Prie l ex 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1971, 106- année, n° 4259 PARTIE 1 PART 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éd iteur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once, In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Officiai Publither 4260 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1971, Vol.106, No.S3 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : 35 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre * o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 197k, 106' année, n° S3 4261 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, Sa et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ADAM ASPHALTE & PAVAGE LTEE.29349 ADEN BUILDING ENTERPRISES INC.31426 ADLON INVESTMENT COMPANY.30761 ALLIED PRESS INC.31100 ALOUETTE CONSTRUCTION LIMITED.30496 AMERICAN TOURIST-AID INC.32140 AMEUBLEMENT LAURENTIEN INC.31852 APEX COMMODITIES INC.29856 APEX HEATERS LTD.29857 L.ARCAND & CIE LTEE.31508 ARCO REALTIES LTD.31288 ARMOR SUPPLY SALES LTD.29564 ARTISTIC ENTERPRISES LTD.31792 L'ATELIER DES ARTISANS DE STE-ADELE INC.129054 LES ATELIERS GRAPHIQUES INC.100440 ATHAMY CO.29312 AUGER & LAQUERRE LTEE.31376 Beaconsfield.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1955 et/and 1956, 1962 à/to 1973 incl.Montreal.1956, 1958 à/to 1973 incl.St-Laurent.1963 à/to 1973 incl.Québec.1956 à/to 1973 incl.L'Abord-à-Plouffe.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl.St-Joseph-d'Yamaska.1956, 1957, 1960 à/to 1973 incl.Montreal.1957 à/to 1973 incl.Montreal.1960 à/to 1973 incl.Montreal.1955, 1956, 1957, 1959 à/to 1973 incl.Sainte-Adèle.1971 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Noranda.1966 à/to 1973 incl. 4262_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3___ Nom de la compagnie Name of the Company AUTO ELECTRONIC SERVICE INC.31374 THEO, AYOTTE i° 28 4289 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date L.P.LEVESQUE A FILS INC.1366-1956 LIBERTY CONSTRUCTION LTD.CONSTRUCTION LIBERTE LTEE 1366-0678 M.V.R.INVESTMENTS LTD.LES PLACEMENTS M.V.R.LTEE 1366-3433 MAINTENANCE SEPT ILES INC.1354-9647 MAISON MOBILES P.E.GONNEVILLE INC.1355-6972 ME ANN A INCORPORATED.MEANNA INCORPOREE 1368-0996 MERCERIE GARAY INC.1355-1312 JEAN YVES MIGNAULT INCORPOREE.1356-3011 LES MODES DE VETEMENTS DE SPORT GEORGES * SOFIA LTEE GEORGE & SOFIA FASHION SPORTSWEAR LTD 1368-0178 MONTREM INC.1366-1048 NAVIRES OCEANOGRAPHIQUES RIMOUSKI INC.1366-2905 OCTOJAN LTEE.1356-6024 PACIFIC KITCHEN CABINET INC.LES ARMOIRES DE CUISINE PACIFIQUE INC.1367-9493 PALETTES DRUMMOND LTEE.DRUMMOND SKIDS LTD.1365-2682 PARK EXTENSION NOVELTIES STORE INC.MAGASIN NOUVEAUTES PARC EXTENSION INC.1356-0065 LES PLACEMENTS LALIBERTE LTEE.1365-8739 PLACEMENTS ROSAL INC.ROSAL INVESTMENTS INC.1368-1812 LES PNEUS MAURICIENS INC.1356-4175 LES PRODUCTIONS LE TAMANOIR INC.1368-0079 PRODUITS CHIMIQUES G.H.LTEE.G.H.CHEMICALS LTD.1368-0624 PROGESTIO INC.1366-2194 Saint-Gabriel.01 05 74 Montreal.26 04 74 Montreal.28 03 74 56.De Bienville.Baie-Comeau.18 03 74 1046.Johnson.Thetford-Mines.08 04 74 Dorval.01 06 74 685.Avenue Laure, Sept-Iles.20 03 74 Route 230, Saint-Pascal.27 03 74 Montreal.30 04 74 Montréal.26 04 74 Rimouski.18 02 74 Saint-Jean.22 06 74 Montréal.26 04 74 Drummondville.30 04 74 655, rue Jarry Ouest, Montréal.24 04 74 Québec.17 04 74 7650 Des Vendéens, Anjou.09 05 74 5350, Nantes, Trois-Riviè.-ts Ouest.01 04 74 1495, Parc Lafontaine, Montréal.30 04 74 1445 Kingsly Avenue, Dorval.02 06 74 2050, boulevard St-Cyrille ouest.03 05 74 Sainte-Foy. 4290 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8 Nom / Name , 1974, Vol.106, No.S3___ PROTECTION INCENDIE D.O.R.LIMITEE.D.O.R.FIRE PROTECTION LIMITED 1367-8990 PROTEK SECURITY AGENCY INC.L'AGENCE DE SECURITY PROTEC INC.1356-2848 PUTTI A FILS INC.1356-2020 RAUER TELEVISION INC.TELEVISION RAUER INC.1367-5517 RENAULT, PIERREFONDS LTEE.1367-3983 RESTAURANT DAN INC.DAN RESTAURANT INC.1354-9480 RESTAURANT LE VIEUX HAMEAU INC.1356-1089 RESTAURANT SAM LEE INC.1356-2913 ROZ HOME FURNISHERS LTD.FOURNISSEURS D'AMEUBLEMENT ROZ LTEE 1356-2871 ST-LAWRENCE PLYWOOD BOXES (1974) LTD.BOITES CONTREPLAQUEES\" ST-LAURENT (1974) LTEE 1356-6088 ROGER ST-PIERRE A FILS INC.1355-4936 SALAFO INC.1355-9208 SAVARD A FRERES LIMITEE.1354-9142 8CORCER INC.1356-2798 SERVICE D'AGENCE ARTISTIQUE S.I.J.LTEE.S.I.J.BOOKING SERVICE LTD.1367-6624 SERVICE DE REPONSES DE VICTORIAVILLE INC.1356-5248 SPECIALITE CAFE GOURMET INC.GOURMET COFFEE SPECIALTY INC.1356-2897 LES SPECIALITES Y.G.LTEE.1356-2856 SPORT G.R.P.LTEE.G.R.P.SPORT LTD.1356-5072 LES 8PORT8 MARC FOURNIER INC.MARC FOURNIER SPORTS INC.1355-6230 STRUCTABEC INC.1355-8136 Incorporation Siège social / Head Office Date 7451, De Chambois, Montréal.23 04 74 39 Terrasse Robert, Chambly.06 12 73 132, Holliday, Sept-Iles.01 05 74 8619, boulevard Lalande, Pierrefonds.29 03 74 14199, boulevard Gouin ouest, 22 03 74 Pierrefonds.892 St.Catherine Street West, 14 03 74 Montreal.199, rue Hayward, Rivière-du-Loup .26 04 74 7062 Henri Bourassa Boulevard, 07 12 73 Charles bourg.6035 Victoria Avenue, Montreal.11 02 74 770, boulevard St-Louis, 15 05 74 Saint-Louis-de-France.171, rue St-Germain Ouest, Rimouski.03 04 74 Saint>- Jean Chrysostome.18 04 74 Chicoutimi.15 03 74 195, boulevard Gréber.07 01 74 Pointe-Gatineau.4103 Mackenzie Court, Chomedey, 29 03 74 Laval.Victoriaville.04 04 74 8aint-Lambert.21 02 74 1490, boulevard St-Paul, Chicoutimi.12 02 74 Angliers.28 01 74 1442 boulevard Jacques-Cartier, 04 04 74 Mont-Joli.2220, Chapdeleine, Suite 908, 11 04 74 Sainte-Foy. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1971, 106' année, n° 23 4291 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date Centre 2000, Laval.18 10 73 4141 Sherbrooke Street West, 09 04 74 Suite 310, Westmount.220 Grande-Allée East, Québec.21 02 74 1661, rue Beaudry, Montréal.09 05 74 Hinchinbrook.21 02 74 Verdun.13 03 74 4601, boulevard des Grandes Prairies, 02 05 74 Saint-Léonard.467, Racine est, Chicoutimi.09 05 74 LES SUPERMARCHES D'ELECTRONIQUES (MONTREAL) INC.ELECTRONICS SUPERMARKETS (MONTREAL) INC.1356-2772 TAPLOS ENTERPRISES LTD.LES ENTREPRISES TAPLOS LTEE 1355-7343 TENUES DE GALA CELEBRITE LTEE.CELEBRITY FORMALS LTD.1355-8960 TRANSPORT SERVANT INC.SERVANT TRANSPORT INC.1368-1515 TRUITCO INC.1356-2921 UROCO INC.1354-7609 VALENTINO ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES VALENTINO INC.1368-0590 LES VOYAGES BONNEAU INC.1356-4042 Le directeur du service dee compagnies, Pierre Debjardins, 57483-0 Pierre Desjardinb.57483-0 Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires à : Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changes BIJOUTERIE J.P.D.INC.12 08 63 08 05 74 Ancien nom / Former name: 3428-63 DOUCET, INC.CENTRE RADIO LOGIQUE DE SAINT- 10 06 64 06 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital.HYACINTHE INCORPOREE.2626-64 CLUB RICHELIEU BUCKINGHAM.28 01 53 06 05 74 1) Étendant les pouvoirs / Extending the 3603-62 powers.2) Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of the immoveable property.ALBERT COUTURIER INC.27 06 68 06 05 74 Étendant les pouvoirs / Extending the 2914-68 powers.O.DALLAIRE LIMITEE.12 04 73 19 02 74 Ancien nom / Former name: 731691 LES ENTREPRISES OSEE DALLAIRE LIMITEE 4292 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.23 Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changée CLIFF DESJARDINS INC.01 06 71 10 05 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital.2862-71 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the tellers patent.LES INVESTISSEMENTS PAGE, INC.29 05 64 30 04 74 Modifiant le capital / Altering the capital 2000-64 LEMOYNE & FRERE AUTOMOBILE LTEE.23 01 61 07 05 74 Étendant les pouvoirs / Extending the 10326-61 powers.MAGASIN JAT (ROBERVAL) LTEE.08 01 58 01 04 74 Modifiant le capital / Altering the capital.10021-58 MALCONISON INC.11 09 62 03 05 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the 13739-62 powers.SEREMAR INC.06 03 67 10 05 74 1) Ancien nom / Former name: 963-67 LES PLACEMENTS R.H.INC.2) Étendant les pouvoirs / Extending the powers.WEBER FARMS INC.21 11 72 05 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the LES FERMES WEBER INC capital.726092 2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 57483-0 Pierre Desjardins.57483-o Director of the Companies Service.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies.Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accepté l'abandon de la charte de: Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date AQUA-GEL INC.15 11 62 07 06 74 14600-62 BAVER BROS.(QUEBEC, INC.27 01 72 07 06 74 BADER FRERES (QUEBEC) INC.720468 CREDIT B.R.S.INC.02 09 65 07 06 74 B.R.S.CREDIT INC.3937-65 DUBER INC.10 07 64 07 06 74 3056-64 GIGNAC & FILS CONSTRUCTION LIMITEE.17 03 59 31 05 74 HOTEL-MOTEL ABENAQUIS LTEE.11 08 64 31 05 74 3656-64 MacDONALD AVENUE INVESTMENTS CORP.14 11 68 04 06 74 14127\u201458 MARCAR INVESTMENT CORP.06 09 68 31 05 74 10158-60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4293 Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date MECHANICAL APPLIANCE AND TRANSMISSION CO.990-29 MEDIC ADMINISTRATION INC.3512-67 LES MINES JAGG INC.(LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) JAGG MINES INC.(NO PERSONAL LIABILITY) 776-68 MOGIS INVESTMENT CORP.12262-59 LA RIVIERA BAKE SHOP LTD.2618-63 ROTSA REALTY CORPORATION.7065-49 ST-HUBERT INVESTMENT INC.11785-57 SODE-AIRE 3 INC.4052-63 PAUL THIBODEAU INC.16470-59 TWINPAK-GILBERT LTD.15897-61 TRANS-RIVER DEVELOPMENT CORP.13020-59 URBITEC LTEE.4197-1969 08 05 29 18 08 67 27 02 68 16 04 69 10 06 63 20 09 49 06 09 67 23 09 63 01 12 69 06 12 61 19 05 69 10 09 69 31 05 74 31 06 74 14 06 74 31 05 74 07 06 74 14 06 74 14 06 74 07 06 74 14 06 74 07 06 74 07 06 74 07 06 74 57483-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes (3e partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ASSOCIATION DES CITOYENS DE FERRAZZANO.1367-2282 L'ASSOCIATION DES COPAINS NOUVELLE-VIE INCORPOREE 1367-6374 L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DU C.E.G.E.P.DE ST-JEROME INC.1356-5015 ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA PLAZA STE-THERESE INC.1367-5269 8148, rue Mirepoix, Saint-Léonard .12 03 74 Montréal.07 03 74 435, rue Fournier, Saint-Jérôme.28 01 74 Sainte-Thérèse.28 03 74 4294 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8.1974, Vol.106, No.S3__ Nom / Xame ASSOCIATION QUEBECOISE DES PRESSES UNIVERSITAIRES 1356-2939 ASSOCIATION RECREATIVE DES EMPLOYES DE LA DIVISION CHALEURS CONSOLIDATED BATHURST DE NEW-RICHMOND 1356-6492 CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION SUR LES AVANTAGES SOCIAUX (C.E.F.A.S.) 1355-6691 CENTRE DE LOISIRS ST-ESPRIT DE QUEBEC INC.1355-2310 CENTRE DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DU QUEBEC INC.1367-7679 CHORALE LES VOIX DU LARGE INC.1356-2780 CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-ATHANASE DE KAMOURASKA INC.1356-2863 CLUB DE L'AGE D'OR TOISON D'OR DE SAINT- SAUVEUR-DES-MONTS 1356-2764 LE CLUB DE L'AGE D'OR DE SACRE-COEUR, INC.1355-2153 CLUB DE L'AGE D'OR STADACONA.1356-2327 CLUB D'ECHECS D'ALMA.1355-2179 CLUB DES HANDICAPES EN MARCHE DE LA RIVE SUD INC.1355-3615 CLUB LOISIRS ET CAMPING DU RICHELIEU INC.1355-1205 CORPORATION DES GENAGOGUES DU QUEBEC.1356-2889 LE FESTIVAL QUEBECOIS DE LA TROMPE DE CHASSE ET DE LA VENERIE 1355-1320 GARDERIE ST-ROCH INC.1356-2822 LES HABITATIONS DE L'OR BLANC INC.1356-6468 LA LIGUE DE TAXIS DE L'AGGLOMERATION STE-FOY SILLERY INC.1356-3614 LA LIGUE DE TAXIS DE LEVIS INC.1356-3606 METIERS D'ARTS DES CANTONS DE L'EST INC.1356-1998 MOUVEMENT POUR L'EPANOUISSEMENT CULTUREL DES \u201e\u201e AMERINDIENS ET DES INUITS MECADI 13o7-o707 Montréal.01 04 74 Incorporation Siège social / Head Office Montréal.28 02 74 New-Richmond.22 05 74 Montréal.08 04 74 280B, 8ième Rue.Québec.25 03 74 Montréal.10 04 74 Gaspé.01 05 74 Saint-Athanase.05 03 74 8, rue Filion, Saint-Sauveur-des-Monts 25 09 73 Sacré-Coeur.12 03 74 1418, Jeanne Mance, Québec.02 05 74 Aima.22 03 74 30.rue Champagnat.Lévis.28 03 74 Saint-Jean.21 03 74 Trois-Rivières.11 03 74 7500, chemin Chambly, Saint-Hubert.20 03 74 440, rue St-François, Québec.01 06 74 Robertsonville.11 01 74 Sainte-Foy.06 12 73 Lévis.28 11 73 Sherbrooke.22 05 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 28 4295 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office Date SECRETARIAT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DU Montréal.13 05 74 SPORT, DU PLEIN AIR ET DU SOCIO-CULTUREL DU QUEBEC 1355-8804 SOCIETE EE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE Montréal.26 03 74 MONTREAL SOCIETY TO SAVE THE HERITAGE OF MONTREAL 1367-4460 CLUB DE SOCCER JEAN TALON INC.1367-9865\t Le directeur du service des compagnies, 57483-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 57483-0 Director of the Companies Service.Administrateurs\tDirectors Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs whose names follow have changed the number of their directors tel qu'indiqué ci-après.as indicated hereinafter.Nom de la Compagnie Name of Company\tDate de constitution\t\tNombre d'à Number\tdministrateurs of directors \tDate of incorporation\t\tAncien nombre Previous number\tNouveau nombre New number ANGLO-CANADIAN PULP AND PAPER MILLS.LIMITED.1901-24\t20\t11 24\t15\t12 ANTIROUILLE S,UD LTEE.SOUTH RUSTPROOFING LTD.4223-67\t15\t12 67\t03\t04 ANTIROUILLE SUD (DIVISION ST-JEAN) LTEE SOUTH RUSTPROOFING (ST-JEAN DIVISION) LTD.714666\t03\t09 71\t03\t06 BROMIS INC.5738-70\t30\t12 70\t03\t06 HEBERT, LE HOUILLIER & ASSOCIES INC____ 1976-65\t05\t05 65\t06\t08 INFRANOR CANADA INC.4041-65\t13\t09 65\t05\t06 PARK LANE CONSTRUCTION LTD.11069-62\tOS\t03 62\t03\t04 RESIDENCE DES ECORES INC.1354-2790\t11\t02 74\t07\t03 UNITRONICS LIMITED.4132-70\t22\t09 70\t03\t04 57483-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 4296 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.28 Changement de nom Change of Name Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies.Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a approuvé les règlements de changement de nom suivants: panies Act, he has approved the by-law6 changing the name of: Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date ASSOCIATION POUR LES DEFICIENTS MENTAUX INC.(REGION SHERBROOKE) 2724-65 LES EDITIONS DE LA TABLE INC.1351-67 LES INDUSTRIES PERMATAC INC.738921 J.T.SPORTSWEAR MFG.LTD.MANUFACTURE DE VETEMENTS DE SPORT J.T.LTEE.738512 SHERBROOKE ASSOCIATION FOR RETARDED 10 06 65 CHILDREN.ASSOCIATION DE SHERBROOKE POUR LES ENFANTS ARRIERES INC.LES EDITIONS DE LA TABLE RONDE INC.29 03 67 LES INDUSTRIELS ASSOCIES G.P.B.INC.03 12 73 FLEXFORM SPORTSWEAR LTD.22 10 73 LES VETEMENTS DE SPORT FLEXEORM LTEE.57483-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Siège social (Art.84) Head office (Art.84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci- whose names follow have changed their head office as indicated après.hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Sjège social Head office Date Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ANALCO INC.20 04 61 970, rue Lecocq, Montréal.2775, Montée St-Aubin, 11819-61 Laval.ARCADE INDUSTRIES LTD.06 02 63 Montréal.24, Place Sicard, Sainte- 659-63 Thérèse.L'ASSOCIATION DES CITES ET VILLES DU 29 07 63 Richmond.160, rue Child, Coaticook.DISTRICT DE SAINT-FRANCOIS.THE ST.FRANCIS DISTRICT CITIES AND TOWNS ASSOCIATION 3056-63 L'ASSOCIATION PROVINCIALE DE L'INDUS- 06 11 62 Québec.66, rue des Erables, TRIE DU BOIS OUVRE DU QUEBEC INC.Victoriaville.14497-62 BENRO INC.23 08 60 Saint-Gervais 13217-60 H.L.BOISVERT INC.26 04 62 Waterville.11741-62 223, boulevard Du Pont, Saint-Nicolas.210, rue Union, Coaticook.LE BOREAL EXPRESS LTEE.26 02 63 466, rue Bonaventure, 2385, rue Chapleau, Sillery.836-63 Trois-Rivières.BROMPTON CONSTRUCTION INC.12 06 69 Bromptonville.1100, rue Ontario, 12710-59 8herbrooke. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 23 4297 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address P.E.BRULE LTD.P.E.BRULE LTEE 15584-61 C.R.D.HOLDING INC.MEUBLES C.R.D.INC.734864 LES CARRIERES D'ARGENTEUIL ET DEUX-MONTAGNES INCORPOREE ARGENTEUIL AND TWO-MOUNTAINS QUARRIES INCORPORATED 651-64 LA CIE SPORAMA LTEE.11814-61 COGEMAR (QUEBEC) LIMITEE.1650-69 CONGRESS HOUSING INC.13069-59 ENTREPRISES HERTEL INC.11754-61 FIBRACAN INC.15818-61 GESTION C.G.LTEE.4278-64 GRANDMONT & FILS LTEE.11458-61 HERCULE EQUIPMENT & PARTS CO.2655-63 LES INDUSTRIELS ASSOCIES G.P.B.INC.738921 LAKESIDE ESTATES INC.12770-61 LAURENTIAN LEASING INC.LOCATION LAURENTIENNE INC.14636-61 LAURENTIDE TRANSPORT INC.15680-61 M.A N.ENTERPRISES INC.2432-64 MEADOWBROOK GOLF CLUB LIMITED.2172-33 MEDICAM INC.12285-61 MEYSOR LTD.10432-62 MONTREAL KITCHEN CABINETS LTD.ARMOIRES DE CUISINES DE MONTREAL LTEE 7990-48 ETIENNE MOREL INC.11177-61 29 11 61 20, Cedars.Aylmer 28 11 73 8140,51e Avenue, Laval-Ouest.335, boulevard Taché, Hull.2563 Est, rue Beaubien, Montréal.01 04 64 Saint-Joseph-du-Lac.69, rue St^André, Saint-André-Est.25 04 61 Isle Maligne, Roberval.481, Sacré-Coeur Ouest.Aima.11 04 69 126, rue StrPierre, Québec.306, Place Youville, C-15, Montréal.22 05 59 Montreal.203.Duflerin Road.Hampstead.21 04 61 154, rue Radisson, 847, Avenue Pratt, TroisRivières.Outremont.30 11 61 870, Avenue Casot, 1890, boulevard Fortin, Québec.Laval.28 09 64 620, rue Arago ouest, 995, boulevard Pierre Québec.Bertrand, Vanier.24 03 61 Saint-Nicépbore.150, rue Hériot.Drummondville.18 06 63 8651.10e Avenue, 888, 6e Avenue, Saint-Michel.Pointe-aux-Trembles.03 12 73 251, Place Colbert, 18, rue Brière, Saint- Sainte-Thérèse.Augustin.01 06 61 5095 Kingston Avenue, 5630 Queen Mary, Montréal.Hampstead.12 10 61 169, St-Jean-Baptiste, 375, boulevard Wilfrid Montmagny.Hamel, Québec.23 11 61 St-Jérôme.10525, Cote de Liesse Road, Dorval.28 05 64 Châteauguay.105, Northview, Montreal West.27 11 33 Lachine.2015 Peel Street, suite 1025, Montreal 08 05 61 Loretteville.2271, rue Robitaille Québec.29 01 62 Montréal.68, boulevard Cartier, Laval-des-Rapides, Laval.13 12 48 Montreal.1755, rue Cunard, Laval.03 03 61 Sherbrooke.232, rue Quenn, Lennox- ville. 4298 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol 106, No.23 Incorporation Siège social Head office [Nom ae la compagnie Name of the company\t\tDate\t\tAncienne adresse PreviWus address\tNouvelle adresse New address NATIONAL LANDSCAPING SERVICE LTD.SERVICE PAYSAGISTE NATIONAL, LTEE 45088-53\t09\t10\t63\t156, rue de Callières, Quebec.\t3e Rang, Saint-Apollinaire.NOVA MANAGEMENT COMPANY LIMITED.SOCIETE DE GESTION NOVA LIMITEE 10831-62\t16\t02\t82\t901 Bleury Street, Montreal.\t5 Neveu Avenue, Beacons-field.HENRI PARENT INC\t31\t03\t64\t\t164, rue Benjamin, Hu- 1268-64\t\t\t\t\tdon, Saint-Laurent.1 M POIRIER ET COMPAGNIE LIMITEE\t08\t08\t63\t\t208, Boulevard Saint-Jean Pointe-Claire.2783-63\t\t\t\t\t PROSER INCORPORATED 1585-71\t18\t03\t71\t2800.rue Descoteaus.Sherbrooke.\t2860.Place Marquette, Laval.R7, CONSTRUCTION CO.LTD.11987-62\t04\t05\t62\t7045, rue Dollier.Saint-Léonard.\t1298, rue Perras, LaSalle.RODIS LTD.\t26\t01\t62\t\t68 Cartier Boulevard, 10407-62\t\t\t\t\tLaval-des-Rapides.RYAN INVESTMENTS LTD.13732-62\t12\t09\t62\t3, rue Belvédère, West-mount\t909 ouest, Boulevard Dorchester, Montréal.SAVARD & DION TRANSPORT INC.2906-64\t08\t07\t64\t2035, rue St-Vallier ouest, Duberger.\t2440.boulevard Hamel, Québec.SHERWOOD AIR SERVICES INC.\t14\t12\t61\tSanmaur .\t978.rue Lisieux, Sher- 16017-61\t\t\t\t\tbrooke LES SPORTIFS DU QUEBEC INC.1900-63\t26\t04\t63\t251.Dorchester sud, Québec.\t5265, 3e Avenue ouest, Charles bourg.57483-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjaroins.57483-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Domicile légal (Art.30) Legal domicile (Art.30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé tel qu'indiqué ci-après.Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have established their principal office or have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ALLIED FOOD DISTRIBUTORS INC.5143-63 ALUMINUM PACKAGING LIMITED.LES PRODUITS D'EMBALLAGE D'ALUMINIUM LIMITEE 6772-53 ARENA MANUFACTURING CO.5207-46 ATLAS PRESS LIMITED.454-22 29-11-63 Montréal.1190, rue Ducharme, Montréal.20-04-53 Montréal.417, Place Louvain, Montréal.04-07-46 Montréal.868, rue Beaumont, Montréal.20-04-23 Montréal.360, rue St-Jacques.suite 1409, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4299 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address B.& L.AGENTS INC.14740-60 BAKER ESTATES LIMITED.4016-47 BALMO LTD.10176-61 BARBECUE JOLIETTE INC.JULIETTE BARBECUE INC.13333-60 BARRETTE & FILS LTEE.14503-60 BENGOR FISH AND GAME CLUB.C.C.P.4-13 BERNARDIN FRERES INC.11401-62 BERTHA REALTY CO.LTD.10395-62 BETTER REALTIES & INVESTMENTS CORPORATION LIMITED 2991-64 BONAGENT, INC.2985-37 BOUDREAU.AUGER & ASSOCIES INC.10776-62 N.BOURASSA LTEE.N.BOURASSA LTD.14991-62 BURTON VILLE CONSTRUCTION INC.666-63 CAMBRAI CLUB INC.14890-60 CAMP NAPOLEON BRISSON INC.C.C.P.24-62 CAPITAL PACKING LTD.LES EMPAQUETAGES CAPITAL LTEE 3871-64 CARRIER ET CORNEAU INC.14372-62 CENTRE FAMILIAL ROUYN-NORANDA INC.ROUYN-NORANDA FAMILY CENTRE INC.4676-63 CENTRES CITADELLE LIMITEE.CITADEL CENTRES LIMITED 2944-64 11-11-60 30-05-47 13-02-61 31-08-60 02-11-60 16-04-43 30-03-62 25-01-62 30-06-64 24-11-37 12-02-62 11-12-62 12-02-63 30-05-61 26-03-62 01-09 64 29-10-62 17-04-64 Chicoutimi.Québec.Montreal.559.rue St-Viateur, Joliette, 510.rue Bécard, Chicoutimi.1275, rue des Artisans, Québec.615 Dorchester Boulevard West, suite 1010, Montréal.110, rue Baby, Joliette.190, rue Collard, Alma .855, rue Tanguay, Alma.Grand'Mère.715.Carré Victoria, Montréal.5452, rue Sherbrooke ouest, Montréal.1445, rue Dorion, Montréal.Montréal.21, rue Dufferin, Granby.Mont-Royal.1500, rue St-Paul, Saint-Césaire.750, 4ième Rue, Grand'Mère.8000, rue St-Denis, Montréal.5890, Monkland, Montréal.5160, rue de Mentana app.4, Montréal.200 rue St-Jacques ouest, bureau 400, Montréal.12.rue St-Joseph.Granby.5500.Côte de Liesse, Mont-Royal.142, Route Rurale numéro 3, Saint-Césaire.Québec.845, rue Joffre, Québec.Chicoutimi.157, rue Langevin, Chicoutimi.Iberville.382, rue Croisettière, Iberville.Chicoutimi.2065, boulevard St-Paul, Chicoutimi.Rouyn.108, rue Dallaire, Rouyn.26-06-64 3440, boulevard St-Laurent, Tour de la Bourse, Montréal.Suite 1300, Montréal.CHAUFFAGE QUEBEC INC.10462-62 CHICOUTIMI FRUIT LTEE.2575-53 31-01-62 404, rue Mailloux, Québec 28-01-53 Chicoutimi.180, rue St-Sauveur.Québec.448, rue St-Jacques, Chicoutimi. 4300 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address LE CLUB AGE D'OR D'ARVIDA ARVIDA GOLDEN AGE CLUB 5001-63 CLUB BOULEAU.C.C.P.37-53 25-11-63 62, rue Centre, Arvida.514.rue Ecole, Arvida.CLUB CACOUCHECH.C.C.P.62-53 CLUB CALUMET BLANC INC.C.C.P.50-62 CLUB DE CHASSE ET PECHE CHOCHOCOUAN C.C.P.8-1954 CLUB DE CHASSE ET DE PECHE STE-ANNE C.C.P.1-1900 CLUB DE CHASSE ET DE PECHE ST-LUDGER INC.C.C.P.53-62 CLUB DE CHASSE & PECHE ST-MAURICE INC.C.C.P.1-1888 LE CLUB DE GOLF DE L'EPIPHANIE INC.14308-62 CLUB DE LA CHAUDIERE C.C.P.20-45 CLUB DE PECHE DU LAC DES QUINZE MILLES C.C.P.13-29 20-04-63 Jonquière.03-09-53 Drummondville.29-06-62 Coaticook.19-12-53 Amos.203, rue Panet, Jonquière.42, rue Holmes, Drummondville.192, rue Orcutt, Coaticook.82, Première Avenue ouest, Amos.12-02-1900 Québec.17-08-62 Saint-Ludger 18-07-1888 La Tuque.24-10-62 98, rue des Sulpiciens L'Epiphanie.24-05-45 Saint-Georges.Il 07 29 Mont-Joli- CLUB DE ST-TITE.C.C.P.2-10 CLUB DES CHUTES BLANCHES.C.C.P.60-48 CLUB DES CINQ CHASSEURS.C.C.P.67-65 CLUB DES MONTS.C.C.P.9-35 CLUB DES ONZE.C.C.P.113-65 CLUB DES TROIS.C.C.P.63-63 LE CLUB DU LIVRE DU QUEBEC INC.3433-64 CLUB DU MAISON DE PIERRE.C.C.P.22-41 CLUB DU NORD____ C.C.P.1-29 CLUB FRONTENAC.C.C.P.58-48 CLUB GEOFFRION.C.C.P.20-43 CLUB LA FLECHE.C.C.P.4-13 15 01 10 08 14 06 26 09 22 11 30 06 12 08 27 08 17 01 12 11 12 11 16 04 10 Drummondville.48 Dolbeau.65 Chandler.35 Québec.65 Hull.53 Montmagny 64 3411.rue St-Denis, Montréal.41 Montréal.29 Shawinigan.48 Saint-Robert-Bellarmin.43 Shawinigan.13 Saint-Tite.1050, rue Moncton, Québec.134, rue Principale, SaintrLudger.922, rue Journeault, La Tuque.200, avenue du Golf, L'Epiphanie.63.29ième Rue est, Saint-Georges.53, rue Pelletier, Mont-Joli 112, rue Lindsay, Drummondville.492, boulevard Walberg, Dolbeau.430, rue Père Eudiste.Chandler.2, avenue Chauveau, Québec.115, rue Isabelle, Hull.Route Rurale numéro 1, Montmagny.1651, rue St-Denis, Mon-réal.4489, rue Papineau, Montréal.603, 5e Rue, Shawinigan.Saint-Robert-Bellarmin.8172, boulevard des Hêtres, Shawinigan.241, rue du Moulin, Saint-Tite. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4301 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address CLUB LAC AU SABLE.02 10 47 Chicoutimi .1022, rue Jacques-Cartier C.C.P.78-47 est, Chicoutimi.CLUB MANON.23 06 65 L'Epiphanie.44, rue des Sulpiciens, C.C.P.83-65 L'Epiphanie.CLUB ST-CHRISTOPHE.12 01 45 Cap-de-la-Madeleine.163, rue Vivier, Cap-de-la- C.C.P.1-45 Madeleine.CLUB SHAWI.23 06 44 Shawinigan.2206, rue Champlain, C.C.P.18-44 Shawinigan.LE COMPTOIR DU MEUBLE INC.13 05 63 183, rue Collard ouest, 425, rue Collard ouest, 2120-63 Aima.Aima.CONSTRUCTION JEAN ET MARTIN LTEE.01 03 74 100.rue Chauma, Ville- 93, Père Giroux, Ville- 1354-2261 neuve.neuve.CORPORATION PHARMACEUTIQUE FRAN- 28 11 34 200, rue Vallée, Montréal.2055, rue Favard, Mont- CAISE LIMITEE real.2327-1934 C.R.CROWLEY LIMITED.30 06 26 Montréal.1396.rue Sherbrooke ouest.1370-26 Montréal.D B SERVICE INC.24 12 63 7372, rue des Erables, 5205, boulevard Métro- 4560-63 app.2, Montréal.politain est, Montréal.DALE DEVELOPMENT CORP.10 11 60 Montreal.2050 Mansfield Avenue.14872-60 Montreal.DAVIE SHIPBUILDING LIMITED.09 01 25 Montreal.759, carré Victoria, Mont- 1-25 réal.DE8SANE FISH AND GAME CLUB.16 05 47 La Tuque.1053, boulevard Duchar- C.CP.48-47 me, La Tuque.DUMAS TRANSPORT INC.02 07 54 Québec.561, rue Turgeon, Québec.11645-54 LES ENTREPRISES GENERALES ST-HYA- 08 02 61 Saint-Hyacinthe.2403, rue Duvernay, CINTHE LTEE Saint-Hyacinthe.10694-61 LES ENTREPRISES R.G.INC.28 01 74 Montréal.630 ouest, boulevard Dor- R.G.ENTERPRISES INC.chester.22e étage, 746250 Montréal.EST SERVICE QUEBEC INC.09 02 73 Sherbrooke.389, rue Victoria, Sher- 730584 brooke.FEDERATION DES OEUVRES DU DISTRICT 11 04 44 Hull.33, boulevard Alexandre DE HULL Taché, chambre 2, Hull.HULL DISTRICT COMMUNITY CHEST 2353-44 FINANCE LOCALE INC.28 09 54 Mont-Joli.1281, rue Jacques Car- (LOCAL FINANCE INC.) tier, Mont-Joli.47814-53 LES FINS CAFES LTEE.18 09 63 4753, rue Lafontaine, 10768, rue Salk, Montréal.2932-63 Montréal.ARNOLD FISHER CORP.02 12 46 Montreal.1455 Sherbrooke Street 8090-46 West, apt.801.Montréal.FREDAR INVESTMENT CORPORATION.22 11 54 Montréal.5465, Chemin de la Reine 12876-54 Marie, No 480, Montréal. 4302 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 Domicile légal Incorporation Legal domicile _ Nom de la compagnie-\u2014 ~ Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address GAMMONT REALTY INC.07 11 61 265 ouest, rue Craig, 1303.rue Greene, suite 15208-61 chambre 350, Montréal.401.Montréal.NIL GIRARD TRANSPORT LTEE.31 03 60 485, rue St-Philippe, Chi- 1777, boulevard Talbot, 11207-60 coutimi.Chicoutimi.GRANTS DIRECT BY MAIL SERVICES INC.29 05 34 Montréal.1061, rue^ St-Alexandre, 1096-34 Montréal.LES HABITATIONS SAINT-LOUIS, LIMITEE.23 02 22 Québec.1600, boulevard Hamel 300-22 ouest, Québec.HAMELIN ELECTRIC INC.01 09 61 Montréal.744, rue Jarry est, Mont- 13880-61 real.THE HOUSE OF GORDON LTD.02 12 60 1 255 University, Mont- 6285 Victoria Avenue.15182-60 real.Montreal.HUGO HOLDINGS LIMITED.17 07 61 276 ouest, rue St-Jacques, 360, rue St-Jacques, 13650-61 Montréal Montréal.HYGRADE CHAMOIS CO.LTD.11 06 42 Montréal.2950, rue Brighton, 3673-42 Montréal.IMMEUBLES CE.BISSON INC.01 04 64 Québec.210, rue Marie de l'Incar- 1460-64 nation, Québec.IMMEUBLES GAUBAU LIMITEE.21 08 63 48, rue St-Pierre, Québec.125, rue Dalhousie, Québec.3573-63 JALROU INC.21 03 62 71, rue St-Pierre, Québec.819, Chemin Ste-Foy, 11245-62 Québec.JORODA ENTERPRISES LTD.10 11 60 Montreal.2050 Mansfield Avenue, 14874-60 Montreal.S.KWIAT INC.13 02 61 Montreal.50 Cremazie Boulevard 10727-61 West, suite 609, Montreal.LABORATOIRES FRANCA INC.23 12 60 170 est, rue Dorchester, 920, rue Port-Royal, FRANCA LABORATORIES INC.Montreal.Montréal.15777-60 LABRADOR FISH AND GAME CLUB.30 11 1898 Rimouski.595, rue St-Germain ouest, C.C.P.15-1898 Rimouski.LAC LA RAQUETTE FISH AND GAME CLUB.09 06 1899 Saint-Lambert.66, rue MacAulay, Saint- C.C.P.6-1899 Lambert.LACOTE REALTIES LIMITED.17 04 42 Montreal.110, boulevard Crémazie 2985-42 ouest, bureau 1200, Montreal.LAMARRE, CAT Y LEVESQUE, & MIREAULT 06 06 47 Montréal.3, Place Ville Marie, suite LTEE.400, Montréal.3703-47 LAVAGE MURAL INC.11 07 63 643, rue Gervais, Trois- 58a, rue René.Trois- 2939-63 Rivières.Rivières.GERALD LEBLOND LTEE.30 07 63 20, rue St-Pierre, Rimouski 183, rue Fiset, Rimouski.3275-63 LETA INC.26 01 62 276 ouest, rue St-Jacques.200, rue St-Jacques ouest, 10405-62 chambre 810.Montréal.Montréal.LORANGER & MOLESWORTH INC.28 03 46 Trois-Rivières.1005, rue Père Daniel, 3043-46 Trois-Rivières.MALO GAS BARS INC.29 12 60 Montreal.5500 St.James West, 16333-60 Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4303 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address MARINE REAL ESTATE INC.12 05 60 10976-60 MARINO RESTAURANT LTEE.22 04 63 8446-53 MARLEX MFG.CO.LTD.10 04 61 11476-61 MARQUIS & FRERES LIMITEE.19 09 61 14714-61 MEDILAB INC.13 06 63 2107-63 MERRY WOOD CLUB.04 02 48 C.C.P.11-48 MIDTERRE REALTY LTD.20 01 61 10358-61 J.S.MITCHELL & CO., LIMITED.20 04 23 597-23 MOZART LTEE (MOZART LTD).29 03 32 477-32 OMNIA-CINE LTD.05 07 63 2918-63 PAN AMERICAN INVESTMENTS LTD.02 11 60 14701-60 PLACEMENTS VALBRO INC.31 03 64 1365-64 PARKTOWN KNITTING MILLS LTD.11 06 63 2550-63 PRODUITS BEL INC.05 05 64 BEL PRODUCTS INC.1832-64 PROVINCIAL ADJUSTMENT INC.18 AJUSTEMENT PROVINCIAL INC.12152-62 QUEBEC BREWERS ASSOCIATION.27 07 43 LASSOCIATION DES BRASSEURS DU QUEBEC.4412-43 GERARD RACINE & FILS INC.16 08 61 14112-61 REGENT PROPERTIES LIMITED.08 06 62 12470-62 RIFA INC.14 02 64 737-64 ST.LAWRENCE CLOTHING CO.LTD.09 03 63 4315-53 SARO METAL INC.23 10 45 6608-45 SAUCISSE DIONNE SAUSAGE INC.24 10 63 46299-63 1231, rue Notre-Dame.1015, rue Notre-Dame, Lachine.Lachine.Québec.1961, rue Bourbonnière, Québec.Montreal.417, rue St-Pierre, Montréal.1040, rue Conseil, Sher- 336, rue Alençon, Sherbrooke, brooke.Québec.225, rue St-Vallier est, Québec.Grand'Mère.411, 8e Rue, Grand'Mère.Montreal.1440 Towers Street, suite 101, Montreal.Sherbrooke.61, rue Wellington sud, Sherbrooke.Québec.350, boulevard Charest est, Québec.1411, rue Crescent, suite 1255, rue University 403, Montréal.suite 612, Montreal.1416 St.Lawrence 1303 Greene Avenue, Boulevard, Montreal.Montreal.Montréal.5125, boulevard St- Laurent, Montréal.7275 St.Urbain Street, Montreal.4150, rue Majeau, Montréal-Nord.05 62 80, rue St-Pierre, Québec.666 St.Urbain Street, Montreal.6868, boulevard Maurice Duplessis, Montréal-Nord.71, rue St-Pierre, suite 416, Québec.Montréal.1080, Côte du Beaver Hall, suite 724, Montréal.Granby.70, rue Principale, Granby.1106, St.Lawrence 5, Place Ville-Marie, Boulevard, Montreal.IBM Building, Suite 1203, Montréal.Montréal.630 Ouest, rue Sherbrooke, Montréal.Québec.95, rue St-Vallier est, Québec.St-Romuald-d'Etchemin.3ième Avenue, Centre Industriel, Saint-Romuald-d'Etchemin.Montréal.440, Sicard, Montréal. 4304 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 8, 1974.Vol.106.No.S3 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie Name of the company\t\tDate\t\tAncienne adresse Previous address\tNouvelle adresse New address \t02\t11\t22\tMontréal.\t3405, St-Donat, Montréal.1800-22\t\t\t\t\t SCOTT * PERCY LIMITED\t16\t04\t64\t\t3300, boulevard Cavendish, 10834-54\t\t\t\t\tMontréal.LES SERVICES MENAGERS ROY LTEE.768-63\t19\t02\t63\t66 est, rue Dorchester, Montréal.\t2073, rue Papineau, Montréal.SHELLDALE HOLDINGS CORP.11260-60\t22\t03\t60\t155 Port Royal West.Montreal.\t455 DesLauriers, Montreal.SIMARD A SIMARD CONSTRUCTION INC.112-63\t08\tni\t63\t333.rue Davis, Arvida.\t207, rue Paré, Arvida.THF.SNELI.IF.R FISH AND GAME CLUB\t.il\t01\til\t\t595, rue St-Germain ouest, Riinouski.C.C.P.2-11\t\t\t\t\t LA SOCIETE DE BIENFAISANCE DES AVEUGLES DU SAGUENAY.DU LAC 8T-JEAN ET DE L'ABITIBI EST ET OUEST INC.3504-43\t22\tH?\t43\tSt-Joseph, Aima.\t90, boulevard Dequen, Aima.SOCIETE DE SERVICES PROFESSIONNELS INC.14149-62\t19\t10\tn\t2950, rue Masson, Montréal.\t4001, Boulevard Métropolitain Est, Suite 500.Montréal.SOGEDIS LTEE.1501-64\t27\tM\tM\t107, rue Ouellet, Rimouski.\t103, rue St-Germain Ouest, Rimouski STOP FIRE LIMITED.\t01\t01\t46\tMontréal.\t9823, rue St-Laurent, Montréal.2521-46\t\t\t\t\t STORAGE LEASEHOLDS INC.\t80\t01\tM\tMontréal.\t1010, rue Ste-Catherine ouest, suite 540, Montréal.455-64\t\t\t\t\t THE THEMI8 CLUB INCORPORATED.\t31\toa\t10\t\t910 Sherbrooke Street West, Montreal.395-19\t\t\t\t\t THERMATIC AIR CONDITIONING LTD.4244-63\tni\t10\tsa\t440, rue Beaumont, Montréal.\t146, chemin Bates, suite 307.Montréal.THERMOTANK (CANADA) LIMITED.\t08\t06\tta\t\t5700, rue Notre-Dame ouest, Montréal.3537-43\t\t\t\t\t JOS TREMBLAY & FILS LTEE.3143-64\t24\t07\t64\t219, rue Ste-Famille, Kénogami.\t14.Parc Industriel, Montréal.\t19\t10\tsa\tMontréal\t250.rue Somerville, Montréal.46162-53\t\t\t\t\t TROIS-RIVIERES AUTO ELECTRIC LTD TROIS-RIVIERES AUTO ELECTRIQUE LTEE 8880-49\t29\t11\t40\tTrois-Rivières.\t2275.rue Bellefeuille.Trois-Rivières.TRUCHON 4 LAROUCHE LTEE.16628-61\t04\tIS\t61\t690, rue Sacré-Coeur, Aima.\t142, rue Sacré-Coeur est, Aima.\t27\tni\t61\tMontré;il\tPlace du Canada, suite 1220, Montréal.11344-61\t\t\t\t\t 1969-64\t01\t06\t04\t908, boulevard Ste-Thérèse.Dolbeau.\t1832.boulevard Walberg, Dolbeau.13003-60\t12\t07\tr,o\t8543, boulevard St-Laurent, Montréal.\t451.rue St-Sulpice.Galerie 2-K.Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins 5'483-o Pierre Desjardins.67483-0 Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4305 Avis divers Municipalité de Lucerne Avis est par les présentes donné que la Municipalité de Lucerne désire présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'être constituée en municipalité de Ville.La municipalité de Ville projetée portera le nom de « La Ville de Lucerne » et aura une population de huit mille cinq cents (8,500) habitants.Les limites de la municipalité de Ville projetée seront les suivants: « Partant du point d'intersection du prolongement de la ligne ouest du Canton de Hull avec la frontière Québec-Ontario; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le prolongement et la ligne ouest du Canton de Hull jusqu'à la ligne separative des Rangs VII et VIH; la ligne separative des Rangs VII et VIII jusqu'à la ligne est du lot 19A, Rang VII; la ligne est du lot 19A, Rang VII; la ligne separative des Rangs VI et VII jusqu'à la ligne est du lot 13A, Rang VI; la ligne est des lots 13A et 13B, Rang VI; la ligne nord des lots 12, 11, 10A et 9, Rang V, jusqu'au côté ouest du boulevard de la Cité des Jeunes (Chemin de la mine de fer) ; puis suivant les limites actuelles de la Cité de Hull, les côtés ouest et sud-ouest dudit boulevard jusqu'au côté nord-ouest du Chemin de la Montagne; les côtés nord-ouest et nord-est dudit chemin en allant vers le sud-ouest et le nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 9B-1 du Rang ÎV; le prolongement et la ligne ouest du lot 9B-1; la ligne nord des lots 9B-3 et 10B du Rang IV; la ligne ouest des lots 10B et 10C du Rang IV; une ligne à travers un Chemin public séparant les Rangs HI et IV et joignant l'extrémité sud-ouest du lot 10C, Rang IV à l'extrémité nord-ouest du lot 10-18 du Rang III; la ligne ouest des lots 10-18, 10-84, 10-47, 10-48, 10-49, 10-90, 10-50, 10-51, 10-91, 10-52 et 10-53 du Rang IH; la ligne sud des lots 10-53, 10-54, 10-12, 10-9, 10-8, 10-7, 9A-17, 9A-16, 9A-25 et 9A-9 ainsi que partie de la ligne sud du lot 9A-8; une ligne dans le lot 9A parallèle au côté ouest du Chemin de la Montagne (Chemin Brickyard) et située à cinq cent vingt-cinq pieds et six dixièmes (525.6') à l'ouest de ce dernier sur une distance de mille cent soixante-quatorze pieds et deux dixièmes (1,174.2') en allant vers le sud; une autre ligne dans le lot 9A allant vers le sud et d'une longueur de six cent dix-sept pieds et neuf dixièmes (617.9') ; une autre ligne dans le lot 9A perpendiculaire au côté nord-ouest du Chemin d'Aylmer et d'une longueur de six cent cinquante-neuf pieds et sept dixièmes (659.7') établie à partir d'un point sur le côté nord-ouest dudit chemin situé à trois cent quatre-vingt-seize pieds et sept dixièmes (396.7') au sud-ouest de son intersection avec le côté ouest du Chemin de la Montagne (Chemin Brickyard); le côté nord-ouest du Chemin d'Aylmer en allant vers le nord-est jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 8C, Rang ni; ledit prolongement et la ligne est du lot 8C Miscellaneous Notice Municipality of Lucerne Notice is hereby given that the Municipality of Lucerne wishes to present to the Lieutenant-Governor in Council a petition for the purpose of being constituted into a Town Municipality.The contemplated Town Municipality shall be named \"La Ville de Lucerne\" \"The Town of Lucerne\" and shall have a population of eight thousand five hundred (8,500) inhabitants.The limits of the proposed Town Municipality shall be as follows: \"Starting from the point of intersection of the extension of the west line of the Township of Hull with the Québec-Ontario border; thence, successively, the following lines of demarcation: the extension and the west line of the Township of Hull up to the dividing line between Ranges VII and VIII; the dividing line between Ranges VH and Vin up to the east line of lot 19A, in Range VH; the east line of lot 19A, in Range VH; the dividing line between Ranges VI and VH up to the east line of lot 13A, in Range VI; the east line of lots 13A and 13B, in Range VI; the north line of lots 12, 11, 10A and 9, in Range V, up to the west side of Cité des Jeunes Boulevard (road to the iron mine); thence, following the present limits of the City of Hull, the west and southwest sides of said Boulevard up to the northwest side of Mountain Road; the northwest and northeast sides of said road proceeding towards the southwest and the northwest up to the extension of the west line of lot 9B-1 in Range IV; the extension of the west line of lot 9B-1 ; the north line of lots 9B-3 and 10B in Range IV; the west line of lots 10B and 10C in Range IV; a line across the public road dividing Ranges III and IV and adjoining the southwest end of lot 10C, in Range IV to the northwest end of lot 10-18 in Range in; the west line of lots 10-18, 10-84, 10-47, 10-48, 10-49, 10-90, 10-50, 10-51, 10-91, 10-52 and 10-53 in Range in; the south line of lots 10-53, 10-54, 10-12, 10-9, 10-8, 10-7, 9A-17, 9A-16, 9A-25 and 9A-9 as well as part of the south line of lot 9A-8; a line in lot 9A parallel to the west side of Mountain Road (Brickyard Road) and located five hundred twenty-five and six-tenths feet (525.6') to the west of said Road, over a distance of one thousand one hundred seventy-four and two-tenths feet (1,174.2') proceeding towards the south; another line in lot 9A proceeding towards the south over a distance of six hundred seventeen and nine-tenths feet (617.9') ; another \\,ae in lot 9A perpendicular to the northwest side ot Aylmer Road extending over six hundred fifty-nine and seven-tenths feet (659.7') in length as measured from a point on the northwest side of said Road located three hundred ninety-six and seven-tenths feet (396.7') to the southwest of its point of intersection with the west side of Mountain Road (Brickyard Road) ; the northwest side of Aylmer Road proceeding towards the northeast up to the extension of the east line of lot 8C, in Range IH; said extension 4306 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, Mi, Vol.106, No.23 et son prolongement dans la riviere des Outaouais jusqu'à la frontière Québec-Ontario; ladite frontière en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 14B, Rang I; le prolongement et la ligne ouest du lot 14B jusqu'au côté sud-est du boulevard Lucerne (ancienne voie de « Hull Electric Railway »); les côtés sud-est et sud dudit boulevard en allant vers le sud-ouest et l'ouest jusqu'à li ligne est du lot 17A, Rang I la ligne est du lot 17A en allant vers le sud et son prolongement dans la rivière des Outaouais jusqu'à la frontière Québec-Ontario; ladite frontière en allant vers l'ouest jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 19, Rang I; ledit prolongement et la ligne ouest du lot 19, Rang I; une ligne à travers le Chemin d'Aylmer et joignant le coin nord-ouest du lot 19, Rang I au coin sud-ouest du lot 19E, Rang II; la ligne ouest des lots 19E, 19B et 19A; Rang II; la ligne nord des lots 1, 2 et la ligne sud des lots 14, 1151, 1153, 2016, 2170.2171.2174 et 2174D du cadastre du Village d'Aylmer; la ligne est du lot 26B, Rang III et son prolongement dans la rivière des Outaouais jusqu'à la frontière Québec-Ontario; ladite frontière en allant vers le nord-ouest jusqu'au point de commencement.» Le tout suivant les plan et description prépares par M.Jean-Paul Alary a.g.sous le numéro 15 316-676A de ses minutes.Daté de Lucerne, district de Hull, ce 28c jour de mai 1974.Le secrétaire de la municipalité de Lucerne, 57558-0 Jf.an G.Ahchambault.ATIKO GOLD MINES LIMITED (No personal liabilitv) LES MINES D'OR ATI KO LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle) Avis est donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, les lettres patentes en date du 14 mars 1974 ont été délivrées par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, constituant en corporation: Des Neiges Lanthier, secrétaire, fille majeure, 2150, de Maisonneuve, Michel Cogger, 3940, Côte-des-Neiges, Gaston Lafleur, 5853, Decelles, appartement 14, tous trois de Montréal, Jean Lefrançois, 41, Morrison, Mont-Royal, et Michel Jette, 207, de Guyenne, Saint-Lambert.Les quatre derniers nommés sont avocats, pour les objets suivants: Faire dos explorations ou des recherches aux fins de découvrir des mines et minerais, sous le nom de « ATI-KO GOLD MINES LIMITED (No personal liability) \u2014 LES MINES D'OR ATIKO LIMITEE (Libre de responsabilité |>ersonnelle) », avec un capital total de $1,000,000 divisé en 1.000,000 d'actions ordinaires, d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de cette compagnie est établi au numéro 1117 ouest, rue Sainte-Catherine, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjaiidins.57483 1354-7559 and the east line of lot 8C and its extension into the Ottawa River up to the Québec-Ontario border; said border, proceeding towards the southwest up to the extension of the west line of lot 14B, in Range I; the extension and the west line of lot 14B up to the southeast side of Lucerne Boulevard (former \"Hull Electric Railway track\"); the .southeast and south sides of said Boulevard proceeding towards the southwest and west up to the east line of lot 17A, in Range I; the east line of lot 17A proceeding towards the south and its extension into the Ottawa River up to the Québec-Ontario border; said border, proceeding towards the west up to the extension of the west line of lot 19, in Range I; said extension and the west line of lot 19, in Range I; a line across Aylmer Road and adjoining the northwest corner of lot 19! in Range I to the southwest corner of lot 19E, in Range II; the west line of lots 19E.19B and 19A, in Range II; the north line of lots 1, 2 and the south line of lots 14, 1151, 1153, 2016.2170, 2171, 2174 and 2174D on the cadastre for the Village of Aylmer; the east line of lot 26B, in Range III and its extension into the Ottawa River up to the Québec-Ontario border; the said border proceeding towards the northwest up to the starting point.\" The wholein accordance w ith the plan and description prepared by Mr Jean-Paul Alary, q.l.s., under number 15 316-676A of his minutes.Dated in Lucerne, District of Hull, this 28th day of May, 1974.Jean G.Archambault, 57558 Secretary of the Municipality of Lucerne.ATIKO GOLD MINES LIMITED (No personal liabilitv) LES MINES DOR ATIKO LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle) Notice is given that under the provisions of the Mining Companies Act, letters patent, bearing date the 14th day of March, 1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating: Des Neiges lanthier, secretary, spinster, 2150 De Maisonneuve, Michel Cogger, 3940 Côte-des-Neiges, Gaston Lafleur.5853 Decelles.Apt.14, all three of Montreal, Jean lefrançois, 41 Morrison, Mount-Royal, and Michel Jette, 207 De Guyenne, St.Lambert.The latter four advocates, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"ATIKO GOLD MINES LIMITED (No personal liability) \u2014 LES MINES D'OR ATIKO LIMITEE (Libre de responsabilité personnelle)\", with a total capital stock of $1,000,000 divided into 1,000,000 common shares of the par value of $1 each.The head office of the company is at 1117 St.Catherine Street West, Montreal, judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service 57483\"° 1354-7559 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4307 COMMUNAUTE TERRE NOUVELLE NEW EARTH COMMUNITY Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des corporations religieuses, chapitre 75 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 21e jour de mai 1974, constituant en corporation régie par la Loi des corporations religieuses, André Gosselin, animateur spirituel, Gertrude Giroux, animatrice spirituelle, tous deux de 10020, rue Laverdure et Luce Gagnon, éduca-trice, 8443, Henri-Julien, tous trois de Montréal.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de 81,000,000.Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-o 1356-6450 A.J.S.METAL INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de situation de domicile légal de la compagnie « A.O.S.METAL INC.» paru dans la Gazette officielle du 18 mai 1974, numéro 20, à la page 3615, en y remplaçant dans ledit nom les initiales « A.O.S.» par \" A.J.S.», de manière que le nom se lise ainsi « A.J.S.METAL INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-0 2430-69 GLOBAL MERCHANDISERS LTD.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de situation de domicile legal de la compagnie « GLOSAL MERCHANDISERS LTD.», paru dans la Gazette officielle du 18 mai 1974, numéro 20, à la page 3620, en y remplaçant dans ledit nom le mot < GLOSAL » par « GLOBAL », de manière que le nom se lise ainsi: « GLOBAL MERCHANDISERS LTD.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57483-0 6005-64 COMMUNAUTE TERRE NOUVELLE NEW EARTH COMMUNITY The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the Religious Corporations Act, Chapter 75 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent, dated May 21, 1974, constituting as a corporation governed by the Religious Corporations Act, André Gosselin, religious group leader, Gertrude Rioux, religious group leader, both residing at 10020 Laverdure Road, and Luce Gagnon, educator, 8443 Henri Julien, all three of Montreal.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is 31,000,000.The head office of the corporation is located in Montreal, Judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57483 1356-6450 A.J.S.METAL INC.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to cerrect the notice of change of legal domicile of \"A.O.S.METAL INC.\", published in the Quebec Official Gazette dated May 18, 1974, number 20, on page 3615, by replacing therein in said name the initials \"A.O.S.\" by \"À.J.S.\", so that the name may read as follows: \"A.J.S.METAL INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57483 2430-69 GLOBAL MERCHANDISERS LTD.Notice is given that under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of change of legal domicile of \"GLOSAL MERCHANDISERS LTD.\", published in the Quebec Official Gazette dated May 18, 1974, number 20, on page 3620, by replacing therein in the said name the word\"GLO-SAL\" by \"GLOBAL\", so that the name may read as follows: GLOBAL MERCHANDISERS LTD.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.6005-64 57483 ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE Avis est donné qu'en vertu des articles 50 et 51 de la Loi de l'Université du Québec (1968, chapitre 66), des lettres patentes ont été accordées le 6 mars 1974, instituant une école supérieure sous le nom de * ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE » et en anglais sous le nom de « INSTITUTE OF HIGHER TECHNOLOGY ».Le sous-ministre de l'éducation, 57486-0 Pierre Martin.INSTITUTE OF HIGHER TECHNOLOGY Notice is given that pursuant to sections 50 and 51 of the University of Québec Act (1968, Chapter 66), letters patent have been granted on March 6, 1974, instituting a professional school under the name of \"ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE\" and in English, under the name of \"INSTITUTE OF HIGHER TECHNOLOGY\".Pierre Martin, 57486 Deputy Minister of Education. 4308 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.28 Cité de la Pointe-aux-Trembles Avis est par les présentes donné que la Cité de la Pointe-aux-Trembles s'adressera à la législature de la province de Québec, à la présente session, pour l'adoption d'une loi aux fins suivantes: 1.Pour autoriser la Cité de la Pointe-aux-Trembles à payer une rente viagère annuelle à Monsieur Alfred Côté, Madame Luc Delorme et Madame Roland Bleau.2.Pour amender l'article 26 de la Loi des cités et villes en ajoutant après le sous-paragraphe (e) du paragraphe 2, un paragraphe permettant à la municipalité de vendre aux conditions fixées par la Commission municipale du Québec tout immeuble acquis avec une restriction imposant qu'il soit utilisé exclusivement pour fins de rue ou de parc lorsqu'un tel immeuble n'est plus requis pour ces fins.3.Pour autoriser la Cité de la Pointe-aux-Trembles à acquérir de gré à gré ou par expropriation certains immeubles pour fins de réserve foncière ou d'habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l'occupation est jugée désuète ou nocive.Et pour toutes autres fins.Let procureur! de la Cité de Pointe-aux-Trembles, Villeneuve, Pigeon, 57515-o Clément & Guilbeault.City of Pointe-aux-Trembles Notice is hereby given that the City of Pointe-aux-Trembles will make an application to the legislature of the province of Québec, during the present session, in order to secure the enactment of a law for the following purposes: 1.To authorize the City of Pointe-aux-Trembles to pay an annual pension to Mr.Alfred Côté, Mrs.Luc Delorme and Mrs.Roland Bleau.2.To amend section 26 of the Cities and Towns Act, for the City of Pointe-aux-Trembles by adding after paragraph («) of subsection 2 a subparagraph permitting the City of Pointe-aux-Trembles to sell, on conditions fixed by the Québec Municipal Commission, any immoveable acquired with the restriction that it be exclusively for the purposes of a street or park when such immoveable is no longer required for such purposes.3.To authorize the City of Pointe-aux-Trembles to acquire by agreement or expropriation any immoveable of which the acquisition is considered appropriate for real estate reserves or housing purposes and for works related to such purposes and any immoveable whose occupancy is considered obsolete or harmful.And for all other purposes.Villeneuve, Pioeon, Clément & Guilbeault, 57515-o Attorneys for the City of Poinle-aux- Trembles.Succession Bertrand Madore Avis est donné que les héritiers de feu Bertrand Madore ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession dudit Bertrand Madore, suivant acte passé devant Me Benoit Boulanger, notaire, le 27 avril 1974, enregistré à Rouyn-Noranda, le 21 mai 1974, sous le numéro 24715.Le notaire, 57521-0 Benoit Boulanger.Estate of Bertrand Madore Notice is given that the heirs of the late Mr Bertrand Madore have accepted, under benefit of inventory, the estate of said Mr Bertrand Madore, by deed executed before Me Benoit Boulanger, notary, on April 27, 1974, registered in Rouyn-Noranda, on May 21, 1974, under number 24715.Benoit Boulanger, 57521 Notary.Succession Gaston Lavignc Avis est ici donné que l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi avec centre national à Limoilou, Québec, No 1445 Chemin de la Canardière, par acte reçu devant Marc Leroux, notaire à Montréal, en date du 25 mai 1973, No 15 765, et enregistré à Montréal sous No 2 439 428, a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de Gaston Lavigne en son vivant demeurant à Outremont.P.Q., No 455 avenue Stuart, et décédé le 28 octobre 1971, dont elle est bénéficiaire résiduaire universelle aux termes de son dernier testament non amendé ni révoqué reçu devant Jean G.Desmeules, notaire, en date du 13 janvier 1970.No 5383.Le présent avis est donné conformément aux dispositions des articles 660 et suivants du Code civil de Québec.Montréal, ce 29 mai 1973.Le notaire, 57506-o Marc Leroux.Estate of Gaston Lavigne Notice is hereby given that l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi with national office in Limoilou, Québec, No.1445 de la Canardière Road, by deed executed before Marc Leroux, notary, in Montreal, dated May 25th 1973, No.15 765, and registered in Montreal under No.2 439 428.has accepted under benefit of inventory the estate of Gaston Lavigne in his lifetime residing in Outremont, P.Q., No.455 Stuart avenue, deceased as of October 28th 1971, whereof it is the universal residuary legatee in terms of his last will and testament not amended nor revoked executed before Jean G.Desmeules, notary, dated January 13th 1970, No.5383.The present notice is given pursuant to the provisions of articles 660 and following of the Québec Civil Code.Montreal.May 29th 1973.57506-o Marc Leroux, Notary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n' S3 4309 Succession Jean-Guy Cloutier Avis est donné que les héritiers de feu Jean-Guy Cloutier ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession dudit Jean-Guy Cloutier, suivant acte passé devant Me Benoit Boulanger, notaire, le 9 avril 1974, enregistré à Rouyn-Noranda, le 10 avril 1974, sous le numéro 24319.Le \u2022procureur du requérant, 57500-o Benoit Boulanger, notaire.Succession Herbert Lawrence Martin Avis est par les présentes donné que Brian Martin et Vera Martin, épouse de Robert Hatfield, ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de feu leur père, Herbert Lawrence Martin, décédé le 9 décembre 1972, en son vivant domicilié à La Salle, Québec, par acte passé devant Me Pierre Senez, notaire, exerçant à 620, ouest, boul.Dorchester, Montréal, le 31 août 1973, et enregistré à Montréal le 7 septembre 1973 sous le numéro 2458063.Les notaires, McLean, Marler, Tees, Watson, 57559-0 Poitevin, Javet & Roberge.Estate of Jean-Guy Cloutier Notice is given that the heirs of the late Jean-Guy Cloutier have accepted, under benefit of inventory, the estate of said Jean-Guy Cloutier according to a deed executed before Me Benoit Boulanger, notary, on April 9, 1974 registered in Rouyn-Noranda on April 10, 1974 under number 24319.Benoit Boulanger, notary.57500 Attorney for the applicant.Estate of Herbert Lawrence Martin Notice is hereby given that Brian Martin and Vera Martin, wife of Robert Hatfield, have accepted under benefit of inventory the estate of their late father, Herbert Lawrence Martin, deceased on December 9th, 1972, in his lifetime domiciled at La Salle, Québec, by deed passed before Me Pierre Senez, Notary, practising at 620 Dorchester Blvd.West, Montreal, on August 31st, 1973, and registered at Montreal on September 7th, 1973, under number 2458063.McLean, Marler, Tees, Watson, Poitevin, Javet & Robekge, 57559-0 Notaries.Changement de nom \u2014 Loi du Change of name \u2014 Act Demandes Applications Joseph Jean Chenel Avis est donné par ces présentes que Joseph Jean Chenel, domicilié et résidant dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, district de Montréal, province de Québec, à 29 rue Chauret présentera incessamment auprès du lieutenant-gouverneur de la province de Québec une requête demandant le changement de son nom de Joseph Jean Chenel à Anthony Randall Chenel; ledit changement de nom affectera sa femme, Lynne Amey, et sa fille Deborah Lee Chenel.Les procureurs de la requérante, 57437-22-2-0 Frumkin, Feldman & Glazman.Mortimer Kapusta Avis est donné par les présentes que Mortimer Kapusta, Exécutif, domicilié à 215 Netherwood Crescent, dans la Ville de Hampstead, district de Montréal, a l'intention de présenter une demande au ministre de la justice en vue d'obtenir une décision du lieutenant-gouverneur en conseil changeant son nom de Mortimer Kapusta à Mortimer Kape.Ce changement sera applicable également à son épouse.Dame Evellin Adelstein Kapusta et aux deux (2) enfants, Shary-April et Ricky, nés de ce mariage.Daté à Montréal, ce 27e jour de mai 1974.Les procureurs du requérant, Mendelson, Rosentzveig, 57498-23-2-0 Shacter, et al.Joseph Jean Chenel Notice is hereby given that Joseph Jean Chenel, domiciled and residing in the Town of Dollard-des-Ormeaux, District of Montreal, at 29 Chauret Ave., Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the Province of Québec for an order changing his name from Joseph Jean Chenel to Anthony Randall Chenel, the said change to affect and accrue to the benefit of his wife, Lynne Amey and his daughter, Deborah Lee Chenel.Frumkin, Feldman & Glazman, 57437-22-2-0 Attorneys for the Petitioner.Mortimer Kapusta Notice is hereby given that Mortimer Kapusta, Executive, of the City of Hampstead, District of Montreal, and therein residing and domiciled at 215 Netherwood Crescent, will present a petition to the Minister of Justice for a decree of the Lieutenant-Governor in Council changing his name from Mortimer Kapusta to Mortimer Kapc, said change of name to have application and to inure to the benefit of his wife, Dame Evellin Adelstein Kapusta as well as their two (2) children, Shary-April and Ricky, born of the said marriage.Dated at Montreal, this 27th day of May, 1974.Mendelson, Rosentzveig, Shacter et al.57498-23-2-o Attorneys for Petitioner. 4310 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, So.23 Marie Yvette Pauline Boudreau Avis est par les présentes donné que mademoiselle Marie Yvette Pauline Boudreau, domiciliée au 1323 Bord-de-l'Eau, Ste-Dorothée.Ville de Laval, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Marie Yvette Hélène Boudreau.Montréal, ce 17e jour de mai 1974.Le procureur de la requérante, 57436-22-2-0 Normand Talbot.Samuel Gerszcnfisz Avis par la présente est donné que Samuel Gerszen-fisz, ingénieur, de la ville et du district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom pour celui de Samuel Shene.Ledit changement de nom sera aussi valable pour son épouse née Nira Melamcd ainsi que sa fille Cigal (ierszenfisz.qui demeurent à la même adresse.Montréal, le 6 mai.1974.Les procureurs du requérant, Chait, Salomon, 57438-22-2-0 Gelber et al avocats.Joseph-Marius Manning Avis est par les présentes donné que Joseph-Marius Manning (connu sous le nom de Joseph-Marius Harvey), résidant à Sacré-Coeur, présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un ordre de changement de son nom en celui de Joseph-Marius Harvey.Baie-Comeau, ce 30 avril 1974.Le procureur du requérant, 57439-22-2-0 Gaston Boivin.Léonard Alphonse O'Neil Prenez avis que Léonard Alphonse O'Neil, demeurant au 3250.rue Forest Hill.app.709, à Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour demander que son nom soit changé en celui de Léonard Alphonse Pierre O'Neil.Montréal, ce 16 mai 1974.Les procureurs du requérant, Briere, Boivin, 57440-22-2-o Paquette & Beaulac.Mohommad Afsshor Tabrizi Avis est par les présentes donné que Mohommad Afsshor Tabrizi, domicilié au 2185, Chapdelaine, appartement 107, Ste-Foy, district de Québec, s'adressera au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Sam Wright.Québec, ce 1er mai 1974.Les procureurs du requérant, Guy Bertrand, 57473-22-2-0 Clément Richard & Ah.Marie Yvette Pauline Boudreau Notice is hereby given that Miss Marie Y'vette Pauline Boudreau, of 1323 Bord-de-l'Eau, Ste.Dorothée, City of Laval, will present a petition to the Lieutenant-governor in council, to obtain an order changing her name to Marie Yvette Hélène Boudreau.Dated this 17th of May, 1974, in Montreal.Normand Talbot, 57436-22-2-0 Sollicitor for the Petitioner.Samuel Gerszenfisz Notice is hereby given that Samuel Gerszenfisz, engineer, of the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the passage of a bill changing his name to that of Samuel Shene.The said change of name will also affect his wife, born Nira Melamed, and also his daughter Cigal Gerszenfisz, who are domiciled at the same place.Montreal, 6th May.1974.Chait, Salomon, Gelber et al advocate, 57438-22-2-0 Attorneys for the applicant.Joseph-Marius Manning Notice is hereby given that Joseph-Marius Manning (known under the name of Joseph-Marius Harvey), living at Sacré-Coeur, Saguenay County, shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Joseph-Marius Harvey.Baie-Comeau, the 30th of April 1974.Gaston Boivin.57439-22-2-0 Attorney for plaintiff.Léonard Alphonse O'Neil Notice is hereby given that Léonard Alphonse O'Neil, residing at 3250, Apt.709, Forest Hill Street, Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed to Léonard Alphonse Pierre O'Neil.Montreal, May 16th, 1974.Brière, Boivin, Paquette & Beaulac, 57440-22-2-o Attorneys for the company.Mohommad Afsshor Tabrizi Notice is hereby given that Mohommad Afsshor Tabrizi, domiciled at 2185 Chapdelaine, Apartment 107, Ste.Foy, District of Quebec, will apply to the Ministre of Justice to change his name to that of Sam Wright.Québec, May 1, 1974.Guy Bertrand, Clément Richard & Ass., 57473-22-2 Attorneys for the petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 197J,, 106' année, n° S3 4311 Moishe Ainbinder Avis vous est donné que Moishe Ainbinder retraité, du 4655 Bonavista, district de Montréal, a l'intention de présenter au lieutenant-gouverneur en conseil une requête pour le changement de son nom en celui de Moses Louis Binder, ce changement de nom devant aussi profiter à son épouse Doris Ainbinder.Montréal, le 22 mai 1974.Les procureurs du requérant, Chait, Salomon, Gelber, Reis 57443-22-2-0 Bronstein & Litvack.Amedeo Lisi Avis est par les présentes donné que Amedeo Lisi, connu sous le prénom de Leo, industriel, domicilié au numéro 235 de la rue du Dauphiné, à St-Lambert, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son prénom de Amedeo en celui de Leo.Chicoutimi, le 24 mai 1974.Les procureurs du requérant, Fkadette, Bekuekon, Cain, 57472-22-2-0 Lamarre & Wells.George Demitre Zarafonites Avis est par les présentes donné que M.George Demitre Zarafonites, résidant et domicilié au 1420 rue St-Mathieu, app.101, en les cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour un décret changeant son nom de George Demitre Zarafonites pour celui de Georges Demitre; le changement de nom devant aussi concerner son épouse Nadine Duncan de la même adresse.Montréal, le 15 février 1974.Mes Archambault, Riou, 57499-23-2-0 Charbo.vneau & Langeher.Laurent Cleary Avis est donné que monsieur Laurent Cleary.résidant à 109 avenue Jacques-Cartier, Donnacona, comté de Portneuf, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Lawrence Cleary.Donnacona, le 7 mai 1974.Les procureurs du requérant, 57526-23-2-0 Aubé et Larochelle, notaires.Harold Adolphus Schacht Avis es', par les présentes donné que Harold Adolphus Schacht, retiré, demeurant au 734 Lacharité, cité de LaSalle.Montréal, P.Q., s'adressera au lieutenant-gouve'.neuren conseil afin d'obtenir un décret changeant ses nom et prénoms en ceux de Harold Sharpe.Montréal le 18 avril 1974.Le procureur du requérant, 5752S-23-2-0 Jean M.DesRosiers, avocat.Moishe Ainbinder Notice is hereby given that Moishe Ainbinder, Retired Gentleman, of 4655 Bonavista, in the District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Moses Louis Binder which change will also benefit his wife, Doris Ainbinder.Montreal, May 22, 1974.Chait, Salomon, Gelber, Reis, Bronstein & Litvack, 57443-22-2-0 Attorneys for Applicant.Amedeo Lisi Notice is hereby given that Amedeo Lisi, known as Leo Lisi, industrial, residing and domicilied at 235 du Dauphiné, in the municipality of St-Lambert, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his given name of Amedeo to Leo.Chicoutimi, May 24th, 1974.Fhadette, Bergeron, Cain, Lamarre & Wells, 57472-22-2-0 Attorneys for the petitioner.George Demitre Zarafonites Notice is hereby given that Mr.George Demitre Zarafonites residing and domiciled at 1420 St-Mathieu Montreal, District of Montreal will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mr.George Demitre Zarafonites to Mr.George Demitre said change of name will also benefit to his wife Nadine Duncan, of the same address.Montreal, February 15, 1974.Mtres Archambault, Riou, 57499-23-2-0 Charbonneau & Langelier.Laurent Cleary Notice is hereby given that Mister Laurent Cleary, residing at 109 Jacques-Cartier Avenue, in the city of Donnacona, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Mister Lawrence Cleary.Donnacona, May 7, 1974.Aube and Larochelle, Notaries, 57526-23-2-0 Attorneys for applicant.Harold Adolphus Schacht Notice is hereby given that Harold Adolphus Schacht retired, residing at No.734 Lacharité, City of LaSalle, Montreal, P.Q., will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his given name and surname to Harold Sharpe.Montreal, April 18 1974.Jean M.DesRosiers, lawyer, 57528-23-2-0 Attorney for the petitioner. 4312 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.23 Marie Liane Rita Lefrançois Avis est par les présentes donné que Marie Liane Rita Lefrançois, étudiante, du 728 ave.Pratt dans la ville de Montréal, a l'intention de présenter une demande au ministre de la justice afin d'obtenir un décret changeant son nom de Lefrançois en Le François.57524-23-2-0 Marie Lefrançois.Léon Abboud Avis est donné par les présentes que Léon Abboud, domicilié à Montréal et résidant au 4837 Vézina, présentera une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Léon Simon.Ce changement sera également applicable à son épouse Francine Monette et sa fille Katie Abboud.57525-23-2-0 Léon Abboud.Joseph Leschinski Avis est par les présentes donné que Joseph Leschinski, lithographe, des ville et district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom Joseph Lechinski en celui de Iser Lev, celui de son épouse Ida Lechinski en celui de Ida Lev et celui de sa fille mineure Beverly (Bella) Lechinski en celui de Beverly (Bella) Lev, ceci à toutes fins que de droit.Montréal, le 15 avril 1974.Les procureurs du requérant.Pollack & Pollack.Suite 1410, 800, boulevard Dorchester ouest, Montréal, Québec.57527-23-2 Marie Liane Rita Lefrançois Notice is hereby given that Marie Liane Rita Lefrançois, student, of 728 Pratt Ave.in the City of Montreal, will present a petition to the Minister of Justice to obtain an order changing his name to Le François.57524-23-2-0 Marie Lefrançois.Léon Abboud Notice is hereby given that Léon Abboud, domiciled in Montreal and residing at 4837 Vézina, will apply to the minister of Justice for an order changing his name to Léon Simon.The said change of name to have application to the benefit of his wife Francine Monette and his child Katie Abboud.57525-23-2-0 Leon Abboud.Joseph Leschinski Notice is hereby given that Joseph Leschinski, Lithographer, of the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for the passage of a bill changing his name from Joseph Leschinski to that of Iser Lev, that of his wife Ida Leschinski to Ida Lev, and that of his minor daughter Beverly (Bella) Leschinski to that of Beverly (Bella) Lev, same to avail for all legal purposes.Montreal, April 15th, 1974.Pollack & Pollack, Attorneys for petitioner.Suite 1410, 800 Dorchester Blvd., West, Montreal, P.Que.57527-23-2-0 Ernest Robert Schacht Avis est par les présentes donné que Ernest Robert Schacht, retiré, demeurant au 4371 Harvard, ville de Montréal, P.Q.s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant ses nom et prénoms en ceux de « Ernest Robert Sharpe ».Montréal, le 18 avril 1974.Le procureur du requérant, 57550-23-2-o Jean M.Desrosiers, avocat.Ernest Robert Schacht Notice is hereby given that Ernest Robert Schacht, retired, residing at No.4371 Harvard, Montreal, P.Q., will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his given name and surname to \"Ernest Robert Sharpe\".Montreal, April 18.1974.Jean M.DesRosiers, laioyer, 57550-23-2-o Attorney for Petitioner.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Stephan Bienstock Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1732 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Samuel Bienstock en celui de Stephan Bienstock.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r., Stephan Bienstock It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Samuel Bienstock to that of Stephan Bienstock by order number 1732, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c., 57486 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n' 23 4313 François Arthur Douillard Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1733 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de François Anatole Douillard en celui de François Arthur Douillard.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.François Arthur Douillard It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of François Anatole Douillard to that of François Arthur Douillard bv order number 1733, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.o., 57486 Deputy Minister of Justice.Aurèle Dumais Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1734 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Joseph Aurellus Dumais en celui de Aurèle Dumais.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Aurèle Dumais It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Aurellus Dumais to that of Aurèle Dumais by order number 1734, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice.Andy Krauss Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1735 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Endre Kertesz en celui de Andy Krauss.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Andy Krauss It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name fo Endre Kertesz to that of Andy Krauss by order number 1735, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robeht Normand, q.c.57486 Deputy Minister of Justice.Sam Solomon Larry Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1736 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Sam Solomon Lerer en celui de Sam Solomon Larry.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Sam Solomon Larry It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Sam Solomon Lerer to that of Sam Solomon Larry, by order number 1736, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice.Reine Lemieux Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1737 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Marie Dolores Gilberte Reine Verret en celui de Reine Lemieux.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Reine Lemieux It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Dolores Gilberte Reine Verret to that of Reine Lemieux by order number 1737, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand q.c., 57486 Deputy Minister of Justice.Miklos John Lendvay Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1738 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Miklos Janos Beres en celui de Miklos John Lendvay.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Miklos John Lendvay It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Miklos Janos Beres to that of Miklos John Lendvay by order number 1738, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice. \u20224311 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.83 Nicholas Michalis Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1739 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Nicholas Papamichalakis (Papamihalacis) en celui de Nicholas Michalis.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-mini sire de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Marie Liette Chantai Roy Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1740 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Marie-Liette Chantai Fraser en celui de Marie Liette Chantai Roy.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-0 Robert Normand, c.r.Nicholas Michalis It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Nicholas Papamichalakis (Papamihalacis) to that of Nicholas Michalis by order number 1739, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice.Marie Liette Chantai Roy-It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie-Liette Chantai Fraser to that of Marie Liette Chantai Roy, by order number 1740, dated May 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice.Joseph Antonio Yuk-Lai Yan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 1741 du 15 mai 1974, d'effectuer le changement de nom de Antonio Yau Yuk-Lai en celui de Joseph Antonio Yuk-Lai Yau.Québec, le 23 mai 1974.Le sous-ministre de la justice, 57486-o Robert Normand, c.r.Joseph Antonio Yuk-Lai Yau It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Antonio Yau Yuk-Lai to that of Joseph Antonio Yuk-Lai Y'au, by order number 1741, dated Mav 15, 1974.Québec, May 23, 1974.Robert Normand, q.c, 57486 Deputy Minister of Justice.Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Application for Surrender of DOMAINE DU LAC DES COPAINS INC.Avis est donné que « DOMAINE DU LAC DES COPAINS INC.» compagnie constituée en vertu de la Loi des compagnies demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Donné à Farnham, ce 27e jour de mai 1974.Le procureur de la compagnie, 57493-0 Jean-Paul Couture.DOMAINE DU LAC DES COPAINS INC.Notice is herebv given that \"DOMAINE DU LAC DES COPAINS INC.\" incorporated under the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Farnham, this 27th day of May, 1974.Jean-Paul Couture, 57493-q Attorney for the company.LES FOURRURES PRIME LIMITEE PRIME FURS LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie « LES FOURRURES PRIME LIMITEE \u2014PRIME FURS LIMITED », corps politique incorporé suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la Ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 29e jour de mai 1974.Le secrétaire, 57536-0 Nick Sacahetsanos.LES FOURRURES PRIME LIMITEE PRIME FURS LIMITED Notice is hereby given that \"LES FOURRURES PRIME LIMITEE \u2014 PRIME FURS LIMITED\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 29th day of May, 1974.Nick Sacaretsanos, 57536-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 juin 1974, 106' année, n° S3 4315 JOKODA ENTERPRISES LIMITED Avis est par les présentes donné qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies, la compagnie « JORODA ENTERPRISES LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 27 mai 1974.Les procureurs de la compagnie, 57494 Frumkin, Feldman & Glazman.JORODA ENTERPRISES LIMITED Notice is hereby given under the provisions of the Companies Act that \"JORODA ENTERPRISES LIMITED\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its Charter.Montreal, May 27th 1974.Frumkin, Feldman & Glazman, 57494-0 Attorneys for the company.REGENT PARLOR FRAME LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « REGENT PARLOR FRAME LTD.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 17 avril 1974.Le secrétaire trésorier, 57495-0 Mme Claire Kashenberg.REGENT PARLOR FRAME LTD.Notice is given that \"REGENT PARLOR FRAME LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, April 17th, 1974.Mrs.Claire Kashenberg, 57495-0 Secretary-Treasurer.GEORGE H.READ & COMPANY LIMITED Avis est par les présentes donné que la compagnie « GEORGE H.READ & COMPANY LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Joliette, le 13 mai 1974.Le procureur de la compagnie.57496-0 Me Jean-Lin Bonin notaire.GEORGE H.READ & COMPANY LIMITED Notice is hereby given that the company \"GEORGE H.READ & COMPANY LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to grant the permission to surrender its charter.Joliette, May 13, 1974.Me Jean-Lin Bonin, Notary, 57496-0 Attorney for the Company.BARAL inc.Avis est, par les présentes, donné que « BARAL INC.», une compagnie constituée sous la Loi des compagnies et ayant son bureau principal en la cité de Joliette, province de Québec demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Joliette, ce lie jour de mars 1974.Le président, 57532-0 Alain Barrette.BARAL INC.Notice is hereby given that \"BARAL INC.\", a company constituted under the Companies Act and having its head office at Joliette, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Joliette, March 11, 1974.Alain Barrette, 57532-0 President.INDIGO BOUTIQUE LTD.BOUTIQUE INDIGO LTEE Avis est donné par les présentes que « INDIGO BOUTIQUE LTD.\u2014 BOUTIQUE INDIGO LTEE », une corporation incorporée suivant la Loi des compagnies et ayant son bureau chef dans les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le 7e jour de mai, 1974.Le président de la compagnie, 57533-0 Saul Lerner.INDIGO BOUTIQUE LTD.BOUTIQUE INDIGO LTEE Notice is hereby given that \"INDIGO BOUTIQUE LTD.\u2014BOUTIQUE INDIGO LTEE\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 7th day of May, 1974.Saul Lerner.57533-0 President of the Company. 4316 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 DOMAINE W.COTE LTEE Prenez avis que la compagnie « DOMAINE W.COTE LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Secrétaire, 57534-0 Wilrose Côté.DOMAINE W.COTE LTEE Notice is given that \"DOMAINE W.COTE LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Wilrose Côté, 57534-0 Secretary.LES ENTREPRISES GERARD INC.Prenez avis que « LES ENTREPRISES GERARD INC.», une compagnie dûment incorporée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 6e jour de mai 1974.Les procureurs de la compagnie, 57535-0 Tessier, Corbeil & Bourbeau.LES ENTREPRISES GERARD INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES GERARD INC.\", duly incorporated pursuant to the Companies Act and having its head office in Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, this 6th day of May, 1974.Tessier, Corbeil & Bourbeau, 57535 Attorneys for the Company.GECOMA LTD.Avis est par la présente donné que la compagnie « GECOMA LTD.», une compagnie dûment constituée sous la Loi des compagnies et ayant son siège social dans les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 30 mai 1974.Les procureurs de la requérante, LlGHTSTONE & RlBACK.Suite 621, 1440 Ste.Catherine St.W., Montréal H3G-1R8 57538-0 GECOMA LTD.Notice is hereby given that \"GECOMA LTD.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the city and district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 30 May, 1974.LlGHTSTONE & RlBACK, Attorneys for Petitioner.Suite 621,1440 Ste.Catherine St.W., Montreal H3G-1R8 57538-0 MACWILLIAM INVESTMENT INC.Avis est donné que la compagnie « MACWILLIAM INVESTMENT INC.», une compagnie constituée d'après la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Québec, fera application auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Québec, ce 29e jour de mai 1974.Les procureurs de la requérante, 57540-o Rivard.Hickson, Sirois & Lemieux.DAVID TARLO CORP.Avis est donné que la compagnie « DAVID TARLO CORP.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 13e jour de mai, 1974.Le procureur de la compagnie, 57544-0 Charles Wolfson, c.r.MACWILLIAM INVESTMENT INC.Notice is hereby given that \"MACWILLIAM INVESTMENT INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Québec will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Québec, this 29th day of May 1974.Rivard, Hickson, Sirois & Lemieux, 57540-o Attorneys for the applicant.DAVID TARLO CORP.Notice is hereby given that \"DAVID TARLO CORP.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 13th day of May, 1974.Charles Wolfson, q.c.57544-q Attorney for the Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1971,, 106' année, n° 28 4317 GAR INVESTMENTS INC.La compagnie e GAR INVESTMENTS INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en lr.ville de Montréal, donne avis qu'elle s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 31e jour de mai 1974.Les procureurs de la compagnie, YeLIN & KlRSHENBLATT.1010 ouest, rue Ste.Catherine, Chambre 940, Montréal 110, Que.57537-o LA SARRE FOREST PRODUCTS LTD.Avis est, par les présentes, donné que « LA SARRE FOREST PRODUCTS LTD.», une compagnie dûment constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à La Sarre, district d'Abitibi, en la province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec pour demander la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de ladite loi.Daté à Montréal, en la province de Québec, le 29e jour de mai 1974.Les procureurs de la compagnie.Desjardins, Ducharme, Desjardins, 57539-0 Tellier, Zigby & Michaud.NILAS INC.Avis est, par les présentes donné, que « NILAS LNC.», une compagnie constituée sous la Loi des compagnies et ayant son bureau principal en la cité de Joliette, province de Québec, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Joliette, ce lie jour de mars 1974.La présidente, 57541-0 Estelle Guilbeault Barrette.GAR INVESTMENTS INC.Notice is hereby given that \"GAR INVESTMENTS INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 31st day of May, 1974.YELIN & KlRSHENBLATT, Attorneys for the company.1010 Ste.Catherine St.West, Suite 940, Montreal 110, Que.57537-0 LA SARRE FOREST PRODUCTS LTD.Notice is hereby given that \"LA SARRE FOREST PRODUCTS LTD.\", a company duly incorporated under Part I of the Companies Act of Québec and having its head office at La Sarre, district of Abitibi, in the Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of said act.Dated at Montreal, in the Province of Québec, this 29th day of May, 1974.Desjardins, Ducharme, Desjardins, Tellier, Zigby & Michaud, 57539-o Attorneys for the company.NILAS INC.Notice is hereby given that \"NILAS INC.\", a company constituted under the Companies Act and having its head office at Joliette, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Joliette, this 11th day of March, 1974.Estelle Guilbeault Barrette, 57541-0 President.SPORTING GOODS DISTRIBUTORS LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie \u2022 SPORTING GOODS DISTRIBUTORS LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, Québec, ce 22e jour d'avril 1974.(Sceau) Le secrétaire, 57543 Wolfe M.Friedman.SPORTING GOODS DISTRIBUTORS LTD.Notice is hereby given that \"SPORTING GOODS DISTRIBUTORS LTD.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 22nd day of April, 1974.(Seal) Wolfe M.Friedman, 57543-0 Secretary. 4318 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.23 SNO JET LTEE SNO JET LTD.Avis est par les présentes donné que « SNO JET LTEE \u2014 SNO JET LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la cité de Thetford Mines, district de Mé-gantic, province de Québec, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 30e jour de mai, 1974.Les procureurs de la compagnie, Stikeman, Elliott, Tamaki, 57542-0 Mercier & Robb.F.W.IMPORTS LTD.Avis est par les présentes donné que ' F.W.IMPORTS LTD.» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.La secrétaire, 57548 Gesa Dissmak.SNO JET LTEE SNO JET LTD.Notice is hereby given that \"SNO JET LTD-\u2014 SNO JET LTEE\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office m the City of Thetford Mines, District of Mégantic, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Que., this 30th day of May, 1974.Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, 57542-0 Attorneys for the company.F.W.IMPORTS LTD.Notice is hereby given that \"F.W.IMPORTS LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.57548-0 Gesa Dissman, Secretary.O.M.S.HOLDINGS LTD.Avis est par les présentes donné que « O.M.S.HOLDINGS LTD.» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.La secrétaire, 57549 Gesa Dissman.O.M.S.HOLDINGS LTD.Notice is hereby given that \"O.M.S.HOLDINGS LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.57549-0 Gesa Dissman, Secretary.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE D'ACCUEIL DE LANORAIE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE D'ACCUEIL DE LANORAIE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Saint-Joseph-dc-Lanoraie, district judiciaire de Joliette.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57483-0 1354-5298 CENTRE D'ACCUEIL DE LANORAIE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services.Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE D'ACCUEIL DE LANORAIE\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of the establishment is located in St.Joseph-de-Lanoraie, Judicial District of Joliette.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57483 1354-5298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n\" S3 4319 CENTRE HOSPITALIER DU SACRE-COEUR Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 8e jour de mai 1974, convertissant « HOPITAL DU SACRE-COEUR DE HULL » constituée le 6 mai 1959 en vertu des dispositions de l'article 14 de la Loi modifiant la charte de la Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, chapitre 176 des lois de 1958-59, en un établissement public sous le nom de « CENTRE HOSPITALIER DU SACRE-COEUR ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE HOSPITALIER ».Le siège social de l'établissement est à Hull, district judiciaire de Hull.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57483-0 1354-5264 CENTRE HOSPITALIER DU SACRE-COEUR The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted letters patent dated May 8, 1974, converting \"HOPITAL DU SACRE-COEUR DE HULL\" incorporated on May 6, 1959 pursuant to the provisions of section 14 of the Act to amend the charter of La Communauté des Soeurs de la Providence, Statutes of 1958-59, Chapter 176, into a public establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER DU SACRE-COEUR\".Said public establishment shall be classified as a \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of the establishment is located in Hull, Judicial District of Hull.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57483 1354-5264 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES MALAUZE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES MALAUZE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement est à Saint-Laurent-de-Matapédia, district judiciaire de Bonaventure.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57483-0 1354-5314 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES MALAUZE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES MALAUZE\".Said public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of this establishment is located in St.Laurent-de-Matapédia, Judicial District of Bonaventure.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57483 1354-5314 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE MONT-JOLI Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE MONT-JOLI ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: «CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement est à Mont-Joli, district judiciaire de Rimouski.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.William Tetley.57483-0 1355-9729 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE MONT-JOLI The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE MONT-JOLI\".Said public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICES CENTRE\".The head office of this establishment is located in Mont-Joli, Judicial District of Rimouski.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57483 1355-9729 4320 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 RESIDENCE STE-ANNE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « RESIDENCE STE-ANNE ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: «CENTRE D'ACCUEIL ».Le siège social de l'établissement est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.57483-0 1354-5280 RESIDENCE STE-ANNE The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting health services and social services, Statutes of 1971, Chapter 48, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"RESIDENCE STE-ANNE\".Said public establishment shall be classified as a \"RECEPTION CENTRE\".The head office of this establishment is located in Montreal, Judicial District of Montreal.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57483 1354-5280 Syndicats professionnels L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SURINTENDANTS DE LA CONSTRUCTION DE LA PROVINCE DE QUEBEC (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 24 avril 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SURINTENDANTS DE LA CONSTRUCTION DE LA PROVINCE DE QUEBEC », avec siège social situé au numéro 4001, boulevard Métropolitain est.suite 400.Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57522-0 SP: 96-73 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 29 avril 1974, il a autorisé le changement de nom de « ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX ».dont la constitution, sous le nom originaire de « ASSOCIATION CATHOIIQUE DES INSTITUTRICES RURALES DU DISTRICT NO.25 », a été autorisée le 28 mars 1938, et dont le siège social est situé à Clermont, en celui de «SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.) », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57497-o SP: 3449-37 Professional Syndicates L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SURINTENDANTS DE LA CONSTRUCTION DE LA PROVINCE DE QUEBEC (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on April 24, 1974, he authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SURINTENDANTS DE LA CONSTRUCTION DE LA PROVINCE DE QUEBEC\", with head office located at 4001 Métropolitain Boulevard East, Suite 400, Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57522 SP: 96-73 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on April 29.1974, he authorized the change of name of \"ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX », whose incorporation, under the original name of \"ASSOCIATION CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES RURALES DU DISTRICT NO.25\", was authorized on March 28, 1938, and whose head office is located in Clermont, to that of \"SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.)\", pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives 57497 SP: 3449^37 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 23 4321 SYNDICAT NATIONAL DU LAIT INC.(Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 29 avril 1974, il a autorisé le changement de nom du .* SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DU LAIT INC.», dont la constitution a été autorisée le 11 décembre 1939.avec siège social à Québec, en celui de « SYNDICAT NATIONAL DU LAIT INC.», et ce.en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57523-0 SP: 2262-39 SYNDICAT NATIONAL DU LAIT INC.(Professional Syndicales Ad) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on April 29, 1974, he authorized the change of name of \"SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DU LAIT INC.\", whose incorporation was authorized on December 11, 1939, with head office in Québec citv, to that of \"SYNDICAT NATIONAL DU LAIT INC.\", the foregoing, pursuant to the Professinal Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.57523 SP: 2262-39 Ministère de l'Éducation Department of Education Municipalité scolaire de Charlesbourg Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire Des Ilets et d'annexer à la municipalité scolaire de Charlesbourg le territoire ci-dessous décrit: Les lots 978-1, 979-1-2, 979-1-3, 979-1-4, 979-1-5, 979-1 (partie non-subdivisée), 981-1,981-A-2,981-A-3-1, 981-A-3-2, 981-A-3-3, 981-A-4 et 981-A (partie non-subdivisée) du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg.Le 14 mai 1974.Le ministre de l'éducation, 57513-23-2-0 François Cloutier.Municipalité scolaire de St-Jérôme Demande est faite de détacher de la municipalité scolaire Des Cascades-I'Achigan le territoire ci-dessous décrit pour l'annexer, pour les catholiques seulement, à la municipalité scolaire de St-Jérôme: Ce territoire comprend en référence au cadastre du canton de Kilkenny les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du coin nord du lot 22B du rang VII-, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord-est des lots 22B et 22A dans chacun des rangs VII, VI, V et IV; la ligne sud des lots 22A, 23, 24 et 25 du rang IV et 26A, 27A, 28A, 29 et 30 du rang V; la ligne sud-ouest des lots 30 du rang V, 30A et 30B du rang VI et 30 du rang VII; enfin, la ligne nord-ouest des lots 30, 29B, 27, 26B, 25D, 25C, 24B, 23B et 22B du rang VII jusqu'au point de départ, cette ligne se prolongeant à travers le lac Connelly.U 29 mai 1974.Le ministre de l'édtication, 57514-23-2-0 François Cloutier.Charlesbourg School Municipality It is hereby requested to detach from the Des llets School Municipality for annexation to the Charlesbourg School Municipality, the territory hereinafter described : Lots number 978-1, 979-1-2, 979-1-3, 979-1-4, 979-1-5, 979-1 (unsubdivided part), 981-1, 981-A-2, 981-A-3-1, 981-A-3-2, 981-A-3-3, 981-A-4 and 981-A (unsubdivided part) on the official cadastre fcr the Parish of Charlesbourg.May 14, 1974.François Cloutier, 57513-23-2 Minister of Education.St.Jérôme School Municipality It is hereby requested to detach from the Des Cascades-I'Achigan School Municipality the territory hereinafter described, for annexation to the St.Jérôme School Municipality, for Roman Catholics only: This territory comprises, with reference to the cadastre for the Township of Kilkenny, the lots or parts of lots and their present and future subdivisions as well as roads, routes, lakes, watercourses or parts thereof, the whole within the limits hereinafter described, to wit: From the north angle of lot 22B in Range VII; thence, successively, the following lines and demarcations: the northeast line of lots 22B and 22A in each of Ranges VII, VI, V and IV; the south line of lots 22A, 23, 24 and 25 in Range J\\' and 26A, 27A, 28A, 29 and 30 in Range V; the southwest line of lots 30 in Range V, 30A, and 30B in Range VI and 30 in Range VII; lastly, the northwest line of lots 30, 29B, 27, 26B, 25D, 25C, 24B, 23B and 22B in Range VII to the startingpoint, this line extending across Lake Connelly.May 29.1974 François Cloutier, 57514-23-2 Minister of Education. 4322_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.33 Le Centre d'informations religieuses Inc.« Le Centre d'informations religieuses Inc.», corporation constituée en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à 1180 rue Bleury, Montréal, s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec afin d'obtenir l'adoption d'une loi visant à abolir et éteindre toutes charges, conditions, obligations ou prohibitions pouvant restreindre l'usage ou l'utilisation des lots 494-1-1 et 494-2 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Laurent), dans la division d'enregistrement de Montréal-Ouest, mentionnées dans l'acte de donation immobilière faite par Olivier Berthe-let en faveur de la Corporation du Collège Sainte-Marie à Montréal, intervenu le 22 octobre 1863 devant les notaires Frechette et Papineau, sous le numéro 4317 de leurs minutes et enregistré le 2 novembre 1863 au bureau d'enregistrement de Montréal-Ouest, de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro B-36340.Montreal, le 20 mai 1974.Les procureurs de la pétitionnaire, Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, 57442-22-4-0 Martin, Beaudoin & Lesage.Le Centre d'informations religieuses Inc.\"Le Centre d'informations religieuses Inc.\", a body politic incorporated under Part III of the Companies Act and having its head office at 1180 Bleury Street, Montreal, will apply to the National Assembly for the adoption of a law to abolish and extinguish all charges, conditions, obligations or prohibitions having the effect of restricting the use or utilization of lots 494-1-1 and 494-2 of the cadastre of the City of Montreal (St.Laurent ward), in the Registration Division of Montreal-West, mentioned in the deed of immoveable gift made by Olivier Berthelet in favor of the Corporation du Collège Ste.Marie à Montréal, dated October 22, 1963, before Notaries Frechette and Papineau, under number 4317 of their records and registered on November 2nd 1863, at the Registry Office of Montreal West, Registration Division of Montreal, under number B-36340.Moutreal, May 20, 1974.Gagnon, df Billy, Cantin, Dionne, Martin, Beaudoin & Lesage, 57442-22-4-q Attorneys for the Petitioner.HOPITAL ST-JEAN DE DIEU Prenez avis que la Communauté des Soeurs de la Charité de la Providence présentera à l'Assemblée Nationale un projet de loi privée, dans le but de se faire donner le pouvoir d'édicter des règlements relatifs au maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité, à la circulation et au stationnement des véhicules dans les limites de la paroisse Saint-Jean de Dieu, de lui permettre de former un corps de police et d'imposer des sanctions aux contrevenants.Les procureurs de la requérante, Monette, Clerk, Michaud, Barakett, 57346-21-4-0 Levesque & Guérette.HOPITAL ST-JEAN DE DIEU Please be advised that the Communauté des Soeurs de la Charité de la Providence will address itself to the National Assembly for it to adopt a Private Bill with object to empower the said congregation to make bylaws respecting the maintenance of peace, order and safety, the movement and parking of vehicles within the limits of the Parish of Saint-Jean de Dieu and to authorize it to establish a police force and impose penalties on offenders.Monette, Clerk, Michaud, Barakett, Levesque et Guérette, 57346-21-4-0 Attorneys for the Petitioner.Succession Pierre de Boucherville Avis est donné par les présentes que Jean E.Béique, domicilié à Westmount, et Yvan Versailles, domicilié à Ville Mont-Royal, agissant en leur qualité de fiduciaires et exécuteurs testamentaires de la succession Pierre de Boucherville, s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec pour l'adoption d'une loi leur permettant d'effectuer le placement des fonds disponibles de cette succession conformément aux dispositions de l'actuel article 981-0 du Code civil, au lieu de conformément aux dispositions de ce même article en vigueur au moment de l'ouverture de la succession.Montréal, le 7 mai 1974.Les avocats des requérants, Kronstrom, Turmel, 57257-20-4-o Desjardins et Villeneuve.Estate of Pierre de Boucherville Notice is hereby given that Jean E.Béique, domiciled in Westmount, and Yvan Versailles, domiciled in the Town of Mount Royal, acting as testamentary trustees and executors of the Pierre de Boucherville Estate, shall apply to the Québec National Assembly for the adoption of an Act enabling them to invest the Estate's available funds according the requirements of article 981-0 of the Civil Code as presently formulated, instead of according to the requirements of this same article as it stood at the opening of the succession.Montreal, May 7th, 1974.Kromstrom, Turmel, Desjardins & Villeneuve, 57257-20-4-o Attorneys for petitioners.Demandes à la Législature Applications to Legislature GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 33 4323 Ville de Bromont Avis public est par les présentes donné que la ville de Bromont s'adressera à l'Assemblée nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour établir un parc écologique et touristique dans les limites de la municipalité: 2.Pour permettre à la ville d'acquérir, de construire et d'entretenir des lacs, cours d'eau et barrages dans son territoire et contracter des emprunts à cette fin; 3.Pour ajouter le paragraphe 2o à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction ; 4.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés: 5.Pour remplacer le paragraphe 2 de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; 6.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 7.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 8.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la ville; 9.Pour autoriser le conseil à adopter par règlement un plan quinquennal de dépenses en immobilisation; 10.Pour répartir tout ou partie du déficit de la ville accumulé au 31 décembre 1972 sur une période n'excédant pas 15 ans et contracter des emprunts à cette fin; 11.Pour ratifier un contrat intervenu entre la ville et la compagnie IBM Canada Ltd.Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 17 mai 1974.Les procureurs de la ville de Bromont, VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, 57389-21-4-0 Beauregard, Paquet & Pinard.Ville de Ste-Agathe-des-Monts Avis public est donné que la Ville de Ste-Agathe-des-Monts s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa Charte sur la matière suivante: 1.Pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la charte de la ville de Ste-Agathe-des-Monts en amendant l'article 13 pour diminuer le nombre des conseillers de huit (8) à six (6); et pour toutes autres fins.Montréal, ce premier jour de mai 1974.Les procureurs de la ville de Ste-Agathe-des-Monts, VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, Beauregard.Paquet & Pinard.57294-20-4-q Town of Bromont Public notice is hereby given that the Town of Bromont will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes: (1) To establish an ecological and touristic park within the limits of the municipality; (2) To authorize the town to acquire, build and upkeep lakes, rivers and dams within its territory and to borrow for this purposes; (3) To add paragraph 2a to article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission certain immoveables acquired with a restriction; (4) To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to enact a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; (5) To replace paragraph 2° of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; (6) To authorize the Council to acquire immoveables, to install public services therein and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; (7) To authorize the Council to constitute by by-law a \"Snow removal expenses stabilization fund\".(8) To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the town; (9) To authorize the Council to enact by by-law a \"Five-year plan for capital expenditures\"; (10) To apportion all or part of the deficit accumulated on the 31st of December 1972 over periods not to exceed 15 years and to adopt borrowing by-laws for such purposes; (11) To ratify a contract intervened between the town and IBM Canada Ltd.And for all other purposes.Montreal, May 17, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57389-21-4-0 Attorneys for the Town of Bromont.Town of Ste-Agathe-des-Monts Public notice is hereby given that the Town of Ste-Agathe-des-Monts will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purpose : 1.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the Town of Ste-Agathe-des-Monts by amending article 13 to reduce the number of councillors from eight (8) to six (6); and for all other purposes.Montreal, May 1st, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, Attorneys for the Town of Ste-Agathe-des-Monts.57294-20-4-o 4324 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol- 106, No.S3 La Commission des écoles catholiques de Montréal Avis public est par les présentes donné que La Commission des écoles catholiques de Montréal s'adresse à l'Assemblée nationale du Québec pour demander l'adoption d'une loi modifiant la loi concernant la Commission des écoles catholiques de Montréal, en ce qui concerne le fonds de dotation et, entre autres, pour prévoir: a) une participation non obligatoire au fonds de dotation; 6) une participation limitée aux instituteurs y participant le jour de l'entrée en vigueur de la loi à être adoptée ou au plus tard le trente (30) juin 1974; c) la possibilité d'arrêt de participation à celui-ci et les remboursements à être effectués dans de tels cas: d) l'application des dispositions de la loi relatives au fonds de dotation, aux instituteurs et institutrices non laïques à compter du 1er juin 1969, et ce, sans autre effet rétroactif.Montréal, le 6 mai 1974.Les procureurs de la requérante, Brvnet, Durand, Durocher & Denis.3737 est, rue Sherbrooke, Montréal.57264-20-4-o Ville de Québec Avis est, par les présentes, donné que la Ville de Québec s'adressera à l'Assemblée Nationale, à sa présente ou à sa prochaine session, pour demander des amendements à sa charte, le chapitre 95 des lois de 1929 et ses amendements, et notamment pour: 1.Modifier certaines dispositions concernant les élections et notamment pour prévoir que le dépôt requis d'un candidat peut être effectué au moyen d'un chèque tiré sur une caisse populaire et que le serment du greffier de chaque bureau de votation doit être prêté devant le président dudit bureau; 2.Déterminer quand et pour quel montant le Comité exécutif peut autoriser une dépenses sans l'autorisation du Conseil et dans quel cas des soumissions publiques doivent être demandées; 3.Déterminer que les baux peuvent être passés devant notaire si le Conseil l'exige; 4.Imposer une taxe de 2% sur toute mutation de propriété.Cette taxe est calculée sur la plus élevée des valeurs suivantes: celle inscrite au rôle d'évaluation ou celle établie lors de la mutation; 5.Permettre au Conseil de déterminer un taux d'escompte et les conditions donnant droit à un escompte sur toute taxe foncière payée avant la date d'exigibilité, et décréter que tout remboursement de taxes municipales ou scolaires porte intérêt au même taux qui ne peut être inférieur à 5%; autoriser le Conseil à modifier, par résolution, le taux d'intérêt fixé pour les arriérés de taxes; 6.Déterminer dans quel délai à chaque année, le trésorier doit transmettre au Conseil un état de la situation financière de la Ville et un relevé des revenus et dépenses de l'année fiscale précédente; 7.Décréter que tous les chèques sont émis sous la signature du trésorier; The Montreal Catholic School Commission Notice is hereby given that the Montreal Catholic School Commission applies to the National Assembly of Québec to request the adoption of a law to amend the law respecting the Montreal Catholic School Commission, concerning its endowment fund, in order to establish: a) a non compulsory participation; 6) a participation restricted to its teachers who are contributing to it at the date of the coming into force ot the proposed law or at the latest June.30th 1974; c) the choice to end the participation to such fund, and the reimbursement of the appropriate sums; d) the full extention of the provisions of the endowment fund to the non lay teachers, as of June, 1st 1969, with no other retroactive effect.Montreal, May the 6th 1974.Brunet, Durand, Durocher & Denis, Attorneys for the Petitioner.3737 Sherbrooke St.East, Montreal.57264-20-4-o City of Québec Notice is hereby given that the City of Québec will apply to the National Assembly, at its present or next session, to request amendments to its charter, chapter 95 of the Statutes of 1929 and its amendments, and namely in order to: (1) Amend certain provisions concerning elections and namely provide that the deposit required from candidates may be made in the form of a cheque drawn on a \"caisse populaire\" and that clerk of each polling station must be sworn in before the returning officer of said station; (2) Determine when and for what amount the Executive Committee may authorize an expenditure without the authorization of the Council and in which case public tenders must be called for; (3) Determine that leases may be passed before a notary if the Council so requires; (4) Impose a 2% tax on any transfer of property.Said tax shall be calculated on the higher of the following property values: the one entered on the valuation role or the one established at the time of the transfer; (5) Allow the Council to determine a discount rate and the conditions giving right to a discount on any real estate tax paid before the date of exigibility, and order that any reimbursement of municipal of school taxes bear interest at the same rate, which may not be lower than 5%; authorize the Council to modify, by resolution, the rate of interest fixed for overdue taxes; (6) Determine within what extent of time each year the Treasurer must submit to the Council a financial statement together with a statement of the City's income and expenses for the preceding fiscal year; (7) Order that all cheques be issued under the Treasurer's signature; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4325 8.Autoriser la Ville à emprunter temporairement pour toute dépense de nature capitale.Cependant, un emprunt à long terme doit être décrété avant que le total de ces emprunts temporaires atteignent la somme de $10,000,000; 9.Autoriser la Ville à modifier, par résolution de son Conseil, un règlement ou une résolution d'emprunt pour augmenter le taux d'intérêt à un taux n'excédant pas celui fixé par l'article 49 de la Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires; 10.Déterminer par règlement que la chaussée de certaines rues est réservée en tout ou en partie à l'usage exclusif de certains véhicules; 11.Déterminer par règlement que le service de déneigement peut inclure le soufflage de la neige à certains endroits; 12.Prévoir que lorsqu'un bâtiment est dans un état tel qu'il peut mettre en danger la vie ou la santé des personnes, le propriétaire peut être tenu de verser aux occupants une indemnité de relocalisation fixée par un juge de la Cour Supérieure lorsque ce dernier ordonne aux occupants d'évacuer l'immeuble, et qu'à défaut par le propriétaire de payer ladite indemnité, la Ville doit le faire pour ensuite se faire rembourser par le propriétaire; 13.Fixer le montant maximum des cautionnements; 14.Réglementer la circulation et le stationnement dans les avenues du parc du Champs de Bataille que la Ville entretient pendant l'hiver; 15.Accorder aux Hurons domiciliés sur la réserve du village huron, les droits de canotage que possèdent les propriétaires riverains; 16.Modifier le mode de nomination des membres de la Commission de l'Exposition et autoriser la Ville à remplacer la Commission par un service; 17.Établir des garages et des parcs de stationnement et réglementer la circulation et le stationnement dans ces endroits ainsi que sur les terrains publics ou privés de la Ville et établir un tarif des prix exigibles et la manière de percevoir les montants fixés pour le stationnement des véhicules dans ces endroits; 18.Modifier la procédure relative aux infractions aux règlements concernant la circulation et le stationnement des véhicules, notamment pour prévoir l'émission de billets d'assignation; pour décréter que celui qui se prévaut de la formule de paiement libératoire doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l'infraction; pour décréter que le propriétaire ou locataire d'un véhicule est responsable des infractions commises avec ce dernier mais qu'il lui est possible de se disculper s'il n'était pas le conducteur; pour prévoir une amende additionnelle dans le cas de condamnation d'un locataire lorsque ce dernier est une compagnie et prévoir que l'immatriculation d'un véhicule doit être suspendue pour trois mois dans le cas de condamnation d'une compagnie propriétaire du véhicule impliqué lors d'infractions; pour statuer qu'aucun point de démérite ne peut être imputé à une personne pour une deuxième (8) Authorize the City to make a temporary loan for any expense of a capital nature.However, a long-term loan must be ordered l>efore the total of these temporary loans reach the sum of $10,000,000; (9) Authorize the City, to amend, by a resolution of its Council, a loan resolution or bylaw to increase the rate of interest to a rate not exceeding the one fixed by section 49 of the Municipal and School Debt and Loan Act; (10) Determine, by a bylaw, that the pavement of certain streets shall be reserved in part or in whole for exclusive utilization by certain vehicles; (11) Determine by a bylaw that the snow removal service may include the blowing of snow at certain places; (12) Make provision so that when a building is in such a state that it can endanger the life or health of the persons who live in it, the proprietor may be obliged to pay to the tenants a relocation indemnity fixed by a judge of the Superior Court when the latter orders the tenants to leave thp building, and that in default of the owner's paying the said indemnity, the City must do so and obtain a reimbursement from the owner; (13) Fix the maximum amount for securities; (14) Control traffic and parking in the Battlefields Park alleys which the City maintains during the winter; (15) Grant to Hurons domiciled on the Huron Village Reservation the canoeing rights held by riverain owners; (16) Modify the nomination procedure for members of the Exhibition Board and authorize the City to replace the Board by a service; (17) Establish garages and parking lots and establish regulations regarding traffic and parking in these places and also on public or private land in the City, and establish a tariff of rates exigible and the method of collecting the amounts fixed for the parking of vehicles in such places; (18) Modify the procedure relating to violation of the bylaws respecting traffic and the parking of vehicles, namely to provide for the issuing of tickets; to order that anyone who avails himself of the full payment method be considered as having been found guilty of the offence; decree that the owner or lessee of a motor vehicle is responsible for any violation committed with such vehicle but that it is possible for him to exonerate himself if he was not the driver; provide for an additional fine in the case of the conviction of a lessee when the latter is a company and make provision for the registration of a motor vehicle to be suspended for a period of three months when such conviction concerns a company that owns the motor vehicle involved in violations; order that no point of demerit may be imputed to any person for a second offence if said person was not notified of the previous offence; author- 4326 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol- 106, No.23 infraction si elle n'a pas été avisée de l'infraction précédente; pour autoriser un agent de la paix à exiger un cautionnement lorsque le contrevenant est domicilié en dehors de la province; 19.Abroger la disposition concernant l'autorisation préalable à la création de la fonction d'agent spécial; 20.Déterminer comment peut se faire la remise d'amendes; prévoir que dans le cas d'une infraction aux règlements relatifs à la circulation et au stationnement, les procédures, jugement et dette peuvent être annulés lorsque, par erreur, une personne à reçu un billet, a été poursuivie ou condamnée à payer une somme; prévoir également la procédure à suivre pour faire reviser un jugement rendu par défaut pour une infraction aux règlements relatifs à la circulation et au stationnement; 21.Pour amender la loi concernant la création de commissions athlétiques (Statuts refondus 1925, chapitre 131) relativement à la composition de ladite commission.Et tous autres amendements qu'elle jugera nécessaires ou utiles pour la bonne administration de ses affaires et dans l'intérêt de ses citoyens.Québec, le 21 mai 1974.Les procureurs de la Ville de Québec, 57399-21-4-0 Bhochu, Simard & Buist.ize a peace officer to require a security when the offender is domiciled outside the Province; (19) Repeal the provision concerning the preliminary authorization for the creation of the office of special officer; (20) Determine the method for the payment of fines; stipulate that in the case of violation of traffic and parking rules, the proceedings, judgment and payment due may be annulled when a person received a ticket, was prosecuted or condemned to pay a fine by mistake; make provision for a procedure for the revision of a judgment rendered by default for the violation of traffic or parking regulations; (21) Amend the Act concerning the Creation of Athletic Commissions (Revised Statutes 1925, chapter 131) with regard to the constitution of said commission.And any or all amendments that it may deem pertinent or necessary for the sound administration of its affairs and in the interest of its citizens.Québec, May 21, 1974.Brochu, Simard & Buist.57399-21 -4 Attorneys for the City of Québec.Succession Arthur Lagueux Avis est, par les présentes, donné que les légataires universels de feu Arthur Lagueux s'adresseront à l'Assemblée Nationale du Québec au cours de la présente session ou de la suivante, pour obtenir l'adoption d'une loi autorisant les exécuteurs-testamentaires et légataires fiduciaires de la Succession de feu Arthur Lagueux à payer, à compter du 18 octobre 1973, nonobstant des dispositions du testament, à sa veuve, sa vie durant si elle ne se remarie pas, ou jusqu'au jour de son mariage, si elle se remarie, un montant de sept cent cinquante dollars (8750.00) par mois et à partager, à parts égales entre ses enfants, le solde des recettes nettes de la Succession.Québec, ce 17e jour de mai 1974.Les procureurs de la pétionnaire, Boilv, Rémii.lard, Henry 57424-22-4-0 & Bouliannk.Estate of Arthur Lagueux Notice is hereby given that the universal legatees of the late Arthur Lagueux shall petition the National Assembly of Québec during the present session or the following one, for the adoption of a bill authorizing the executors and trustees of the estate of Arthur Lagueux to pay to his widow, notwithstanding the provisions of the will, an amount of seven hundred and fifty dollars ($750.00) per month, from October 18, 1973, throughout her life is she does not remarry or until the day of her marriage, should she remarry, and to divide into equal shares between her children, the residue of the estate.Québec, May 17, 1974.Boily, Rèmillard, Henry & Boulianne, 57424-22-4 Attorneys for petitioner.Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Québec du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, comté de Saguenay.Québec Real Estate Assessment Board of Revision Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act, I hereby order that the limits of the territory of the Québec District of the Québec Real Estate Assessment Board of Revision be modified to include therein the territory of the Municipality of Havre-St.Pierre, County of Saguenay. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n' S3 4327 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.Québec, le 16 mai 1974.Le ministre des affaires municipales, 57501-o Victor C.Goldbloom.Cité de Rivière-du-Loup Le lieutenant-gouverneur en conseil par son arrêté No 1903-74 du 22 mai 1974, conformément à l'article 43 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), a approuvé le règlement No 650 du conseil municipal de la cité de Rivière-du-Loup, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la paroisse de Saint-Pat rice-de-la-Rivière-du-Loup, comté de Rivière-du-Loup, dont description apparaît ci-après, à la cité de Rivière-du-Loup; ce règlement entrera en vigueur à compter de la date de la publication du présent avis.Ce territoire est le suivant: Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, dans le comté municipal de Rivière-du-Loup, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle ouest du lot 936; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté sud-est de l'emprise du chemin de fer de la compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada (lot cadastral numéro 1012) en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne separative des lots 958 et 963; ladite ligne separative de lots et partie de la ligne separative des lots 1045 et 1046 jusqu'à un point situé au sud-est et à une distance de six cents pieds (600 pi) du côté sud-est de l'emprise du chemin des Raymond, distance mesurée le long de ladite ligne separative de lots; une ligne à travers les lots 1046, 1047,_ 1048, 1049, 1050, 1052 et 1053 et parallèle audit côté sud-est en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 1053 et 1054; partie de ladite ligne separative de lots en allant vers le nord-ouest sur ladite distance de six cents pieds (600 pi); le côté sud-est de l'emprise du chemin des Raymond en allant vers le sud-ouest jusqu'au prolongement de la ligne separative de lots jusqu'à un point situé au nord-ouest et à une distance de deux cents pieds (200 pi) du côté nord-ouest de l'emprise du chemin des Raymond, distance mesurée le long de ladite ligne separative de lots; une ligne à travers les lots 940, 938 et 936 et parallèle audit côté nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 936; enfin, partie de ladite ligne sud-ouest en allant vers le nord-ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire détaché de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, comté municipal de Rivière-du-Loup, et annexé à la cité de Rivière-du-Loup.Le sous-ministre des affaires municipales, 57501 -o Roch Bolduc.The present order shall come into force on the date of its publication in the Quebec Official Gazette.Québec, May 16, 1974.Victor C.Goldbloom, 57501 Minister of Municipal Affairs.City of Rivière-du-Loup Notice is given that, by Order number 1903-74, dated May 22, 1974, and pursuant to section 43 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.1964, Chapter 193), the Lieutenant-Governor in Council has approved Bylaw number 650, adopted by the Municipal Council of the City of Rivière-du-Loup, ordering that that part of the territory of the Parish of St.Patrice-de-Ia-Rivière-du-Loup, County of Rivière-du-Loup, described hereinafter, be annexed to the City of Rivière-du-Loup; this Bylaw shall come into force on the date of the publication of this notice.Said territory is described as follows: A territory presently forming part of the Municipality of the Parish of St.Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, in the Municipal County of Rivière-du-Loup, and comprising, in reference to the cadastre for the Parish of St.Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, the lots of parts thereof and their present and future subdivisions, together with the roads, watercourses or parts thereof, the whole comprised within the limits described hereinafter, namely : starting from the apex of the west angle of lot 936; thence, successively, the following lines of demarcation: the southeast side of the railroad right-of-way of the Canadian National Railways Company (cadastral lot number 1012) in a northeasterly direction up to the dividing line between lots 958 and 963; said dividing line between lots and part of the dividing line between lots 1045 and 1046 up to a point located to the southeast of, and at a distance of six hundred feet (600') on the southeast side of the right-of-way of the Raymond family road, said distance being measured along said dividing line between lots; a line across lots 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052 and 1053 and parallel to the said southeast side, in a southwesterly direction up to the dividing line between lots 1053 and 1054; part of said dividing line between lots in a northwesterly direction over said distance of six hundred feet (600'); the southeast side of the right-of-way of the Raymond family road in a southwesterly direction up to the extension of the dividing line between lots 940 and 944; said extension and part of said dividing line between lots up to a point located to the northwest of, and at a distance of two hundred feet (200') on the northwest side of the right-of-way of the Raymond family road, said distance being measured along said dividing line between lots; a line across lots 940, 938 and 936 and parallel to said northwest side, in a southwesterly direction up to the southwest line of lot 936; lastly, part of said southwest line in a northwesterly direction up to the starting point; which limits determine the territory detached from the Municipality of the Parish of St.Patrice-de-la-Rivière-du-Loup, municipal County of Rivière-du-Loup, and annexed to the City of Rivière-du-Loup.Roch Bolduc, 57501 Deputy Minister of Municipal Affairs. 4328 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol- IPG, No.S3 Ville de Mont-Joli Le lieutenant-gouverneur en conseil par son arrêté No 1684-74 du 8 mai 1974.conformément à l'article 43 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, chapitre 193), a approuvé le règlement No 220 du conseil municipal de la ville de Mont-Joli, modifié par la résolution dudit conseil en date du 30 janvier 1974, et décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la paroisse de Sainte-Flavie, comté de Rimouski, dont description apparaît ci-après, à la ville de Mont-Joli; ce règlement entrera en vigueur à compter de la date de la publication du présent avis.Ce territoire est le suivant: Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la paroisse de Sainte-Flavie, dans le comté municipal de Rimouski, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Flavie les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle ouest du lot 193; de là, successivement, les lignes et démarrâtions suivantes: partie de la ligne separative des rangs I et II en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne nord-est du lot 197-145; partie de ladite ligne nord-est jusqu'à un point situé au nord-ouest et à une distance de cent pieds (100 pi.) du côté nord-ouest du chemin du Deuxième rang, distance mesurée perpendiculairement audit côté nord-ouest; une ligne parallèle et distante de cent pieds (100 pi.) du côté nord-ouest dudit chemin en allant vers le sud-ouest jusqu'à sa rencontre avec une ligne située au sud-ouest et parallèle et distante de cent trente pieds (130 pi.) de la ligne separative des lots 195 et 196; ladite ligne parallèle en allant vers le sud-est jusqu'à un point situé au nord-ouest et à une distance de six cents pieds (600 pi.) de la ligne nord-ouest du lot 545 (emprise de chemin de fer), distance mesurée parallèlement aux lignes latérales de lots; une ligne parallèle à la ligne nord-ouest dudit lot 545 en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 194; partie de ladite ligne nord-est en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 545 (emprise de chemin de fer) ; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 193; le prolongement de ladite ligne nord-est à travers le lot 545 (emprise de chemin de fer) et partie de la ligne nord-est dudit lot 193 jusqu'à la ligne separative des rangs II et III; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 191 et 192; partie de ladite ligne separative de lots et son prolongement jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 545 (emprise de chemin de fer) ; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne separative des lots 192 et 193; enfin, partie de ladite ligne separative de lots en allant vers le nord-ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire détaché de la municipalité de la paroisse de Sainte-Flavie, comté municipal de Rimouski, et annexé à la ville de Mont-Joli.Le .sous-ministre des affaires 7nunicipales, 57501-o Roch Boldic.Town of Mont-Joli The Lieutenant-Governor in Council, by his Order number 1684-74, dated May 8, 1974, pursuant to section 43 of the Cities and Town Act, (R.S.Q.1964, Chapter 193), has approved bylaw number 220 adopted by the Municipal Council of the Town of Mont-Joli, amended by a resolution of said Council dated January 30, 1974, ordering the annexation to the Town of Mont-Joli, of a part of the territory of the Parish of Ste.Flavie, County of Rimouski, described hereinafter; this bylaw shall come into force on the date of the publication of this notice.This territory is described as follows: A territory presently forming part of the Municipality of the Parish of Ste.Flavie, in the Municipal County of Rimouski, comprising, with reference to the cadastre for the Parish of Ste.Flavie, the lots or parts thereof and their present or future subdivisions along with the roads, streets, railroad right-of-way, watercourses or parts thereof, the whole comprised within the following boundaries, namely: starting from the apex of the west angle of lot 193; thence, successively, the following lines of demarcation: part of the dividing line between Ranges I and II in a northeasterly direction up the northeast line of lot 197-145; part of said northeast line up to a point located to the northwest and at a distance of one hundred feet (100 ft) on the northwest side of the Second Range Road, said distance calculated perpendicularly to said northwest side; a line parallel to and one hundred feet (100 ft) from the northwest side of said road proceeding towards the southwest up to the point where said line meets a line located to the southwest, parallel to and one hundred and thirty feet (130 ft) from the dividing line between lots 195 and 196; said parallel line in a southeasterly direction up to a point located to the northwest and at a distance of six hundred feet (600 ft) from the northwest line of lot 545 (railroad right-of-way), said distance calculated in a direction parallel to the lateral lines of lots; a line parallel to the northwest line o said lot 545 in a southwesterly direction up to the northeast line of lot 194; part of said northeast line in a southeasterly direction up to the northwest line of lot 545 (railroad right-of-way); part of said northwest line in a southwesterly direction up to the northeast line of lot 193; the extension of said northeast line across lot 545 (railroad right-of-way) and part of the northeast line of said lot 193 up to the dividing line between Ranges 13 and III; part of said dividing line between ranges in a southwesterly direction up to the dividing line between lots 191 and 192; par of said dividing line between lots and its extension up to the northwest line of lot 545 (railroad right-of-way); part of said northwest line in a northeasterly direction up to the dividing line between lots 192 and 193; lastly, part of said dividing line between lots in a northwesterly direction up to the starting point; which limits determine the territory detached from the Municipality of the Parish of Ste.Flavie, Municipal County of Rimouski, and annexed to the Town of Mont-Joli.Roch Bolduc, 57501 Deputy Minister of Municipal Affairs. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4329 Avis de révocation de droits miniers Prenez avis qu'en vertu de l'arrêté numéro 1785-74 du 15 mai 1974, le lieutenant-gouverneur en conseil a révoqué les droits miniers autres que l'or et l'argent sur les terrains suivants: Canton de Lingwick, (Mégantic-Compton) : Rang F: les lots 1, 2, 3, 6, 7 et 8 (cad.: 1, 2a, 26, 3a, 36, 6, 7a, 76, 8a et 86); le 1/20 indivis des droits de la British American Land Co.sur les lots 4 et 5, (cad.: 4a, 46, 4c et 5) ; Rang IX: la demie N.B.du lot 23, les 2/3 S.E.du lot 25, les 2/3 S.E.de la 1/2 S.O.du lot 28, (cad.: 236, 256, 25c et 286); le 1/20 indivis des droits de British American Land Co.sur les lots suivants: lots 20, 21, 29, 30, 31, (cad.: 20a, 206, 20c, 21a, 216.21c, 29, 30 et 31); Rang X: la demie N.E.du lot 23, (cad.: 236) ; le 1/20 indivis des droits de la British American Land Co.sur les lots 28, 29, 30 et 31, (cad.: 28a, 286, 29, 30 et 31); Rang XI: la demie N.E.du lot 27 et la demie S.O.du lot28, (cad.: 276, 28a); le 1/20 indivis des droits de British American Land Co.sur les lots suivants: la demie N.E.du lot 26, la demie S.O.du lot 27 et la demie S.O.du lot 28, (cad.: 266, 27a et 286); Canton de Dudswell, (Mégantic-Compton) : Rang V: les lots 8, 9, 10 et 1/2 S.E.de la 1/2 S.E.du lot 11, (cad.:8.9a, 96, 10a, 106, 10cet lia); Rang VI: le lot 8, la demie S.O.du lot 9, (cad.: 8a, 86 et 9a); le 1/20 indivis des droits appartenant à la British American Land Co.sur la demie S.E.de la demie N.E.du lot 9, (cad.: 9b); Cet avis est donné en conformité avec l'article 209 de la Loi des mines (1965, 1ère session, ch.34 et modifications).Donné à Québec, ce 24e jour de mai 1974.Le sous-ministre, 57519-0 J.-G.Fredette.Notice of revocation of mining rights Notice is given that, pursuant to Order in Council No.1785-74 dated May 15, 1974, the Lieutenant-Governor in Council has revoked the mining rights, other than those applying to gold and silver, on the following lands: Township of Lingwick (Mégantic-Compton) : Range F: lots 1, 2, 3, 6, 7 and 8 (cad.: 1, 2a, 26, 3a, 36, 6, 7a, 76, 8a and 86); the undivided 1/20 of the rights of the British American Land Co.on lots 4 and 5, (cad.: 4a, 46,4c and 5) ; Range IX: the N.E.half of lot 23, the S.E.2/3 of lot 25, the S.E.2/3 of the S.W.half of lot 28, (cad.: 236, 256, 25c and 286); the undivided 1/20 of the rights of the British American Co.on the following lots: lots 20, 21, 29, 30, 31, (cad.:20a, 206, 20c, 21a, 216, 21c, 29, 30 and 31); Range X: the N.E.half of lot 23, (cad.: 236); the undivided 1/20 of the rights of the British American Land Co.on lots 28, 29, 30 and 31 (cad.: 28a, 286, 29, 30 and 31); Range XI: The N.E.half of lot 27 and the S.W.half of lot 28, (cad.: 276, 28a); the undivided 1/20 of the rights of the British American Land Co.on the following lots: the N.E.half of lot 26, the S.W.half of lot 27 and the S.W.half of lot 28, (cad.: 266, 27a and 286) ; Township of Dudswell, (Mégantic-Compton) : Range V: lots 8, 9, 10 and the S.E.half of the S.E.half of lot 11, (cad.: 8, 9a, 96, 10a, 106, 10c and 11a); Range VI: lot 8, the S.W.half of lot 9, (cad.: 8a, 86 and 9a); the undivided 1/20 of the rights of the British American Land Co.on the S.E.half of the N.E.half of lot 9, (cad.: 96); This notice is given in conformity with section 209 of the Mining Act (Statutes of 1965, First Session, Chapter 34 and its amendments).Given in Québec, this 24th day of May 1974.J.-G.Fredette, 57519-0 Deputy Minister.Révocation de concessions minières Prenez avis que les concessions minières ci-après énumérées seront révoquées en faveur de la couronne par le ministre, conformément aux articles 202, 204 et 205 de la Loi des mines (ch.34 des Lois du Québec, 1965, 1ère session, et amendements), pour défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article 119 de cette loi, à moins que la taxe et les frais de publication n'aient été payés dans les 90 jours qui suivront la dernière publication de cet avis: Revocation of mining concessions Pursuant to section 202, 204 and 205 of the mining Act (Québec Statutes 1965, 1st session, ch.34 and modifications), the Minister will revoke for failure to pay the annual tax provided for in section 119 of the said act, the following mining concessions unless the tax and the cost of publication be paid within ninety days following the last publication of this notice: Ministère des Richesses Department of Natural naturelles Resources 4330 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.23 District électoral\tCanton on paroisse\tNo de la concession\tNuméro des lots ou des blocs\tSuperficie en acres\tDate d'émission\tLettres patentes Electoral district\tTownship or parish\tConcession number\tLots or blocks number\tArea in acre\tDale of emission\tLetters patents Laurentides-\t\t396.\tLot 27, rang IV.\t105.43.\t22-03-52\t04-05-67 Labelle Mégantic Compton Papineau.Papineau.Roberval.\t\t\t\t\t\t \tHampden Buckingham\t19.\t\t114.\t\t06-09-29 \t\t313\tSouthern half of lots 41 and 4S, range I.\t50.\t18-11-40\t \t\t334\tNortheastern quarter of the lot 14, range XI.\t50.\t02-03-45\t02-05-55 \tDequen.Preissac.\t407.\tNorthern half of the tot IS, range I.\t50.\t08-03-53\t Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda\t\tP.95.\tSouthern half of the lot S, range III.Bloc E.\t114.\t17-06-16\t13-12-18 \tBousquet.\t236.\tBlock E.\t621.\t02-10-28\t05-03-29 \t\t\tBlocks 6 to 16 incl.\t\t\t Québec, le 00 mai 1974.Québec, May 00, 1973.Le sous-ministre, J-G.Fredette, 57479-22-2-0 .I.-G.Fredette.57479-22-2-q Deputy Minister.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Assurances Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Insurance THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED », dont le siège social est situé à Londres, Angleterre, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA », dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 2 janvier 1974; Attendu que la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED » sont annulés à compter du 1er mai 1974.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er mai 1974.Pour le minisire des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le Surintendant des assurances, 57509-23-2-o Roger-A.Camaraire.THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED\", whose head office is situated at London, England, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\", whose head office is situated at Toronto, Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 2nd of January 1974; Whereas \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"THE STATE ASSURANCE COMPANY LIMITED\" are cancelled as from the 1st of May 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 57509-23-2-o Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4331 GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED Avis d'annulation de 'permis et de certificat d'enregistrement Attendu que la « GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED », dont le siège social est situé à Londres, Angleterre, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec la «GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA », dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 2 janvier 1974; Attendu que la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que la « GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED » sont annulés à compter du 1er mai 1974.Donné an bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er mai 1974.Pour le ministre des institutions financières.compagnies et coopératives de la province.Le Surintendant des assurances, 57507-23-2-o Roger-A.Camaraire.ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que la «ROYAL EXCHANGE ASSURANCE », dont le siège social est situé à Londres, Angleterre, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec la «GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA », dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 2 janvier 1974; Attendu que la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA » est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que la «ROYAL EXCHANGE ASSURANCE » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de la « ROYAL EXCHANGE ASSURANCE » sont annulés à compter du 1er mai 1974.Donné au bureau du Service des assurances.Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er mai 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de lu province.Le Surintendant des assurances, 57508-23-2-o Roger-A.Camaraire.GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED\" whose head office is situated at London, England, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"GUAR-, DIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\", whose head office is situated at Toronto, Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 2nd of January 1974; Whereas \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"GUARDIAN ASSURANCE COMPANY LIMITED\" are cancelled as from the 1st of May 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 57507-23-2-0 Superintendent of Insurance.ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"ROYAL EXCHANGE ASSURANCE\" whose head office is situated at London, England, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\", whose head office is situated at Toronto, Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 2nd of January 1974; Whereas \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"Royal Exchange Assurance\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"ROYAL EXCHANGE ASSURANCE\" are cancelled as from the 1st of May 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger-A.Camaraire, 57508-23-2-o Superintendent of Insurance. 4332 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED », dont le siège social est situé à Hong Kong, Chine, laquelle compagnie était dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec, a réassuré toutes ses affaires dans la province de Québec avec la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA », dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, en vertu d'un contrat de réassurance intervenu entre ces deux compagnies le 2 janvier 1974; Attendu que la « GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA », est dûment autorisée à faire affaires dans la province de Québec; Attendu que « UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED » s'est conformée aux dispositions de l'article 103 de la Loi des assurances; En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et le certificat d'enregistrement de « U- NION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED » sont annulés à compter du 1er mai 1974.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives le 1er mai 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province.Le Surintendant des assurances, 57510-23-2-o Roger-A.Camaraire.FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA », dont le siège social est situé à Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique, a cessé de faire affaires dans le Québec le 15 mars 1974; Attendu que ladite compagnie a produit au Service des assurances, le 15 mars 1974, une déclaration assermentée à l'effet qu'elle n'avait, au 15 mars 1974, aucune obligation au Québec.En conséquence, avis est par les présentes donné que les permis et certificat d'enregistrement de « FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA » sont annulés à compter du 15 mars 1974.Donné au bureau du Service des assurances, ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 15 mai 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la Province, Le Surintendant des assurances, 57421-22-2-0 Roger-A.Camaraire.UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED Notice of Cancellation of License and Certificate of Registration Whereas \"UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED\", whose head office is situated at Hong Kong, China, which company was duly authorized to do business in the Province of Québec, has reinsured all its business in the Province of Québec with \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\", whose head office is situated at Toronto, Ontario, according to a reinsurance agreement entered into by these two companies on the 2nd of January 1974; Whereas \"GUARDIAN INSURANCE COMPANY OF CANADA\" is duly authorized to do business in the Province of Québec; Whereas \"UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED\" has complied with the provisions of section 103 of the Québec Insurance Act; Consequently, notice is hereby given that the license and certificate of registration of \"UNION INSURANCE SOCIETY OF CANTON, LIMITED\" are cancelled as from the 1st of May 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 1st of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire, 57510-23-2-o Superintendent of Insurance.FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Notice of Cancellation of Licence and Certificate of Registration Whereas \"FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA\", whose head office is situated at Seattle, Washington, United States of America, has ceased to do business in Québec as from the 15th of March 1974; Whereas the said company has filed, on the 15th of March 1974, with the Insurance Branch, a sworn declaration to the effect that it had, as of the 15th of March 1974, no obligations in Québec.Therefore, notice is hereby given that the licence and certificate of registration of \"FIRST NATIONAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA\" are cancelled as from the 15th of March 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 15th of May 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Roger A.Camaraire.57421-22-2-o Superintendent of Insurance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 23 SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW-YORK Avis de changement de nom Avis est par les présentes donné que « SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW-YORK », constituée en corporation sous l'empire des lois de l'état de New-York, États-Unis d'Amérique, et enregistrée au Service des assurances du Québec sous le numéro 468, a changé son nom en celui de « NORTH AMERICAN COMPANY FOR PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE ».Donné à Chicago, Illinois, États-Unis d'Amérique, le 1er avril 1974, Le Vice-Président, 57422-22-2-0 Thomas-F.Newman, Jr.Assemblée nationale Projet de loi référé à une Commission parlementaire Avis public est par les présentes donné que le projet de loi 22 intitulé: * Loi sur la langue officielle » a été référé, après la première lecture, pour étude à la commission élue permanente de l'Éducation, des Affaires culturelles et des Communications.Les personnes ou groupes qui désirent se présenter ou se faire entendre devant cette commission ont jusqu'au 10 juin 1974, 17 heures, pour déposer au secrétariat des commissions parlementaires 100 exemplaires de leur mémoire, accompagnés de 200 copies d'un bref résumé.Le tout devra être expédié à la compétence de M.Jacques Pouliot, Secrétaire des Commissions, Chambre 2 \u2014 Édifice A \u2014 Téléphone 643-2722.La première séance de cette commission aura lieu le 11 juin 1974 à 16 heures au Salon rouge de l'Assemblée nationale.Québec, ce 21 mai 1974.Le secrétaire des Commissions, 57393-21-3-o Jacques Pouliot.Curatelle publique Succession Harold-Gordon Gale Succession de Harold-Gordon Gale, en son vivant de 68, rue St-Louis Québec, Que.décédé le 7 juin 1970.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57488-0 4333 SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK Notice of change of name Notice is hereby given that \"SERVICE FIRE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK\", incorporated under the laws of the State of New York, United States of America, and registered with the Department of Insurance of Québec under number 468, has changed its name to \"NORTH AMERICAN COMPANY FOR PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE\".Given at Chicago, Illinois, United States of America, the 1st of April 1974.Thomas F.Newman, Jr., 57422-22-2-0 Vice President.National Assembly National Assembly Bill referred to a Parliamentary Committee Public notice is hereby given that following first reading, Bill 22 \"Official Language Act\" has been referred to the Parliamentary Committee on Education, Cultural Affairs and Communications.Persons or groups who wish to appear before or be heard by this Committee must deposit, before 5 o'clock on June 10th one hundred copies of their briefs together with two hundred copies of a short summary.All documents or memoirs should be forwarded to Jacques Pouliot, Secretary of Committees, Room 2, Building A, Phone number 643-2722.The first meeting will take place on June 11th at the Salon Rouge, National Assembly, at 16 hours.Québec, May 21, 1974.Jacques Pouliot, 57393-21-3-0 Secretary of Committees.Public Curatorship Estate of Harold-Gordon Gale Estate of the late Harold-Gordon Gale, in his lifetime of 68, St.Louis Québec, Que.deceased June 7, 1970.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address, given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57488-0 4334 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 Succession Adrien Hardy Succession de Adrien Hardy, en son vivant de 11784, rue Drapeau Montréal-Nord, P.Q.décédé le 28 septembre 1967.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, houl.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 57487-0 Estate of Adrien Hardy Estate of the late Adrien Hardy, in his lifetime of 11784, Drapeau Street Montreal-North P.Q.deceased September 28, 1967.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address, given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57487-0 Succession Ariette Tremblay Succession de Ariette Tremblay en son vivant de 478.rue St-Pierre Nord St-Constant, Que.décédée le 20 février 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971).il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal, Que.H2N 1N6 57489-0 Succession Georges Schneider Succession de Georges Schneider, en son vivant de St-Rémi, comté de Verchères, décédé le 17 décembre 1972.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent.Montréal.Que., H2N 1N6 57556-0 Succession Marien Sirois Succession de Marien Sirois, en son vivant de 409, boul.Grand-Pabos, Chandler, comté de Gaspé-Sud, décédée le 15 juin 1971.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal, Que., H2N 1N6 57557-0 Estate of Ariette Tremblay Estate of the late Ariette Tremblay in her lifetime 478, St.Pierre North St.Constant, Que., deceased February 20, 1971.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address, given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 57489-o Estate of Georges Schneider Estate of the late Georges Schneider, in his lifetime of St-Rémi, County of Verchères, deceased on December 17, 1972.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57556-0 Estate of Marien Sirois Estate of the late Marien Sirois, in his lifetime of 409, Grand-Pabos Blvd., Chandler, County of Gaspé-South, deceased on June 15,1971.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec 9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que., H2N 1N6 57557.0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année.n° S3 4335 Succession Léo-Paul Rousseau Succession de Léo-Paul Rousseau, en son vivant de Ville de Brossard décédé le 3 mai 1971 à Trois-Rivières.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal.H2N 1N6 57511-0 Estate of Léo-Paul Rousseau Estate of the late Léo-Paul Rousseau, in his lifetime of Ville de Brossard deceased May 3rd 1971 in Trois-Rivières.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address mentioned below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal.H2N 1N6 57511-0 Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Cité de Saint-Léonard Comté d'Olier Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Gaston Pion, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 8400 rue Lacordaire, Saint-Léonard, comté d'Olier, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 25 juin 1974 pour l'achat de 83,502,000 d'obligations de la cité de Saint-Léonard, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera caculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 83,502,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975 .8 42,000 15 07 1976.48,000 15 07 1977.58,000 15 07 1978.65,000 15 07 1979.75,000 15 07 1980 .91,000 15 07 1981.108,000 15 07 1982.124,000 15 07 1983.142,000 15 07 1984.160,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.City of St.Léonard County of Olier Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Gaston Pion, Secretary-Treasurer, at the City Hall, 8400 Lacordaire Street, St.Léonard, County of Olier, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 25, 1974 for the purchase of a bond issue of 83,502,000 for the City of St.Léonard, dated July 15, 1974 and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15, 1974.Redemption table \u2014 $8,602,000 \u2014 20 years Date Capital 15 07 1985.8176,000 15 07 1986.194,000 15 07 1987.211.000 15 07 1988.230,000 15 07 1989 .249,000 15 07 1990 .265,000 15 07 1991.284,000 15 07 1992.307,000 15 07 1993.330,000 15 07 1994.343,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year. 4336 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8.1974, Vol.106, No.23 2\" Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $343.000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $343.000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Saint-Léonard s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 1146 \u2014 $81,000 \u2014 aqueduc et égouts; 1181 \u2014$225,000 \u2014aqueduc et égouts; 1200 \u2014$940,000 \u2014 aqueduc, égouts, autres; 1205 \u2014 $400,000 \u2014 voirie; 1242 \u2014 $990,000 \u2014 aqueduc et égouts; 1255 \u2014 $840,000 \u2014 voirie; 1265 \u2014 $26,000 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue mardi, le 25 juin 1974 à 8.00 heures du soir, Hôtel de ville, 8400, rue Lacordaire, Saint-Léonard, comté d'Olier, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Léonard (Comté d'Olier), ce 30 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, Gaston Pion.Hôtel de ville, 8400, rue Lacordaire, Saint-Léonard, comté d'Olier.Québec.H1R-3B1 Téléphone: 321-7630, code 514.57554-0 2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $343,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $343,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of St.Léonard agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 1146 \u2014 $81,000 \u2014 waterworks and sewers; 1181 \u2014 $225,000 \u2014 waterworks and sewers; 1200 \u2014 $940,000 \u2014 waterworks, sewers and others; 1205 \u2014 $400,000 \u2014 roads; 1242 \u2014 $990,000 \u2014 waterworks and sewers; 1255 \u2014 $840,000 \u2014 roads; 1265 \u2014 $26,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting or of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Tuesday, June 25, 1974 at 8:00 o'clock p.m., at the City Hall, 8400 Lacordaire Street, St.Léonard.County of Olier, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Léonard, County of Olier, May 30, 1974.Gaston Pion, Secretary- Treasurer.City Hall, 8400 I-acordaire Street, St.Léonard, County of Olier, P.Q.H1R-3B1 Telephone: 321-7630, code 514.57554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 23 4337 Paroisse de Saint-Mathias Comté de Rouville Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Madame Normande Vigeant, secrétaire-trésorier, jusqu'à 4:30 heures de l'après-midi Hôtel de ville, 37, route des Épinettes, C.P.39, Saint-Mathias, comté de Rouville, P.Q., et par après jusqu'à 8:00 heures du soir, École Pointe-Olivier, 278 boul.Richelieu, Saint-Mathias, comté de Rouville, P.Q., mercredi, le 26 juin 1974, pour l'achat de $597,500 d'obligations de la paroisse de Saint-Mathias, comté de Rouville, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9% ni supérieur à 10% payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juilet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $597,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975.$ 19,500 15 07 1976.22,000 15 07 1977.24,000 15 07 1978.26,000 15 07 1979 .29,000 15 07 1980 .31,000 15 07 1981.34,000 15 07 1982.38,000 15 07 1983 .42,000 15 07 1984 .45,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $30,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juillet 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut Parish of St.Mathias County of Rouville Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Normande Vigeant, Secretary-Treasurer, until 4:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 37 Des Épinettes Road, Post Office Box 39, St.Mathias, County of Rouville, P.Q.and there after until 8:00 o.clock p.m., at Pointe-Olivier School, 278 Richelieu Boulevard, St.Mathias, County of Rouville, P.Q., on Wednesday, June 26, 1974, for the purchase of a bond issue of $597,500 for the Parish of St.Mathias, County of Rouville, dated July 15,1974 and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9% nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each différent rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15,1974.Redemption table \u2014 $597,600 \u2014 20 years Date Capital 15 07 1985.$ 5,000 15 07 1986 .6,000 15 07 1987.6,000 15 07 1988.7,000 15 07 1989 .8,000 15 07 1990.8,000 15 07 1991.9,000 15 07 1992.10,000 15 07 1993.10,000 15 07 1994.218,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds siwuld not be for an amount less than $30,000 and ii greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of July 15, 2004 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one 4338 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 juillet 1994 au montant de 8218,000 comprend un solde de 8206,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 07 1995.813,000 15 07 1996.15,000 15 07 1997.16,000 15 07 1998.17,000 15 07 1999.19,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $218,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de Saint-Mathias s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 158 \u2014 81,434 \u2014 aqueduc, égouts; 170 \u2014 82,336 \u2014 aqueduc, égouts; 174 \u2014 81,430 \u2014 aqueduc, égouts; 177 \u2014 83,800 \u2014 aqueduc, égouts; 187 \u2014 811,500 \u2014 aqueduc, égouts; 188 \u2014 810,000 \u2014 aqueduc, égouts; 201 \u2014 820,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 202 \u2014 8234,000 \u2014 aqueduc, égouts; 209 \u2014 $300,000 \u2014 aqueduc, égouts; 213 \u2014 88,500 \u2014 aqueduc, égouts; 214 \u2014 84,500 \u2014 aqueduc, égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 26 juin 1974, à 8:00 heures du soir, École Pointe-Olivier, 278, boulevard Richelieu, Saint-Mathias, comté de Rouville, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Mathias (Comté de Rouville), ce 29 mai 1974.La secrUaire-trêsorière, Mme Normande Vigeant.Hôtel de Ville, 37, route des Épinettes, C.P.39, Saint-Mathias, Comté de Rouville, Québec.J0L-2G0 Téléphone : 658-2841, code 514.57505-o of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of July 15, 1994 in the amount of 8218,000 includes a balance of 8206,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 07 2000.$21,000 15 07 2001.23,000 15 07 2002.25,000 15 07 2003.27,000 15 07 2004.30,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than S218,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of St.Mathias agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 158 \u2014 $1,434 \u2014 sewers and waterworks; 170 \u2014 $2,336 \u2014 sewers and waterworks; 174 \u2014 $1,430 \u2014 sewers and waterworks; 177 \u2014 $3,800 \u2014 sewers and waterworks; 187 \u2014 $11,500 \u2014 sewers and waterworks; 188 \u2014 $10,000 \u2014 sewers and waterworks; 201-820,000 \u2014 sewers, waterworks and roads; 202 \u2014 $234,000 \u2014 sewers and waterworks; 209 \u2014 8300,000 \u2014 sewers and waterworks; 213 \u2014 88,500 \u2014- sewers and waterworks; 214 \u2014 84,500 \u2014 sewers and waterworks.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, June 26,1974, at 8:00 o'clock p.m., at Pointe-Olivier School, 278 Richelieu Boulevard, St.Mathias, County of Rouville, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Mathias, (County of Rouville) May 29,1974.Mrs.Normande Vigeant, Secretary-Treasurer.Town Hall, 37 Des Épinettes Road, Post Office Box 39, St.Mathias, County of Rouville, Québec.J0L-2G0 Telephone: 658-2841, code 514.57505 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4339 La commission scolaire de Sherbrooke Siège social: 895, rue Bowen Sud, Sherbrooke, P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Marcel Simoneau, directeur général, Centre administratif, 895 sud, rue Bowen, Sherbrooke, comté de Sherbrooke, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mardi, le 25 juin 1974, pour l'achat de $644,500 d'obligations de la commission scolaire de Sherbrooke, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $644,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975.$16.000 15 07 1976.17,500 15 07 1977.19,000 15 07 1978.20,500 15 07 1979.21,500 15 07 1980.24,000 15 07 1981.25,500 15 07 1982.28,000 15 07 1983.30,500 15 07 1984.33,000 La commission scolaire de Sherbrooke se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $60,000 et si supérieur à ce The Sherbrooke School Board Head Office: 895 Bowen Street South, Sherbrooke, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Marcel Simoneau, Director-General, at the Administration Centre, 895 Bowen Street South, Sherbrooke, County of Sherbrooke, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, June 25, 1974, for the purchase of a bond issue of $644,500 for the Sherbrooke School Board, dated July 15, 1974 and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as show in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15, 1974.Redemption table \u2014 $644,500 \u2014 SO years Date Capital 15 07 1985.$26,000 15 07 1986.29,000 15 07 1987.32,000 15 07 1988.34,000 15 07 1989.38,000 15 07 1990.41,000 15 07 1991.45,000 15 07 1992.50,000 15 07 1993.54,000 15 07 1994.60,000 The Sherbrooke School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $60,000 and if greater than the latter amount. 4340 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106.No.S3 dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $60,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Sherbrooke s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 9 décembre 1963 \u2014 $67,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 26 février 1974 \u2014 $2,500 \u2014 frais de refinancement; 8 avril 1974 \u2014 $575,000 \u2014 agrandissement du centre administratif.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue à 8 heures du soir, mardi, le 25 juin 1974, Centre administratif.895 sud, rue Bowen, Sherbrooke, comté de Sherbrooke, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sherbrooke (Comté de Sherbrooke), ce 4 juin 1974.Le directeur général, Marcel Simoneau.Centre administratif, 895 sud, rue Bowen, Sherbrooke, (Sherbrooke), Québec.Téléphone: 562-3881, code 819.57562-o Commission scolaire régionale Louis-Hémon Siège social : 930, boulevard Sacré-Coeur, Dolbeau, (Roberval), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné André Perron, directeur général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi.Bureau administratif, 930, boulevard Sacré-Coeur, Dolbeau, comté de Roberval, P.Q., et par après jusqu'à 8.00 heures du soir.École Notre- the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 15,1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $60.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Sherbrooke School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: December 9, 1963 \u2014 $67,000 \u2014 loan renewal; February 26, 1974 \u2014 $2,500 \u2014 refinancing costs; April 8,1974 \u2014 $575,000 \u2014 extension of Administration Centre.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held at 8.-00 o'clock p.m., on Tuesday, June 25, 1974, at the Administration Centre, 895 Bower Street South, Sherbrooke, County of Sherbrooke, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Sherbrooke (County of Sherbrooke), June 4, 1974.Marcel Simoneau, Director-General.Administration Centre 895 Bowen Street South, Sherbrooke, (Sherbrooke), Québec.Telephone: 562-3881, code 819.57562 The Louis-Hémon Regional School Board Head Office: 930 Sacré-Coeur Boulevard, Dolbeau, County of Roberval, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, André Perron, Director-General, until 4:30 o'clock p.m., at the Administration Office, 930 Sacré-Coeur Boulevard, Dolbeau, County of Roberval, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m.at Notre-Dame-des-Anges School, Mistassini, County of Rober- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 83 4341 Dame-des-Anges, Mistassini, comté de Roberval, P.Q., mercredi, le 26 juin 1974, pour l'achat de 82,080,000 d'obligations de la commission scolaire régionale Louis-Hémon, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 82,080,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975.841,000 15 07 1976 .44,000 15 07 1977.49,000 15 07 1978 .53,000 15 07 1979 .58,000 15 07 1980.63,000 15 07 1981.68,000 15 07 1982 .75,000 15 07 1983.81,000 15 07 1984 .89,000 La commission scolaire régionale Louis-Hémon se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une autre partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 8207.000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne val, P.Q., on Wednesday, June 26, 1974, for the purchase of a bond issue of 82,080,000 for the Louis-Hémon Regional School Board, dated July 15, 1974, and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15, 1974.Redemption table \u2014 $8,080,000 \u2014 80 years \tDate\t\tCapital 15\t07\t1985.\t.$ 97,000 15\t07\t1986.\t.106,000 15\t07\t1987.\t.115,000 15\t07\t1988.\t.124,000 15\t07\t1989.\t.135,000 15\t07\t1990.\t.148,000 15\t07\t1991.\t.161,000 15\t07\t1992.\t.176,000 15\t07\t1993.\t.190,000 15\t07\t1994.\t.207,000 The Louis-Hémon Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-vear fixed-term bonds will not be for an amount less than 8207,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption table appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 15, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only 4342 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.38 devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $207,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale Louis-Hémon s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 24 janvier 1973 \u2014 $620,000 \u2014 construction d'un complexe polyvalent à Dolbeau: 29 août 1973 \u2014 $1,460,000 \u2014 construction d'un complexe polyvalent à Mistassini.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mercredi, le 26 juin 1974, à 8.00 heures du soir, École Notre-Dame-des-Anges, Mistassini, comté de Roberval, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Dolbeau (Comté de Roberval), ce 3 juin 1974.Le directeur général, André Perron.Bureau administratif, 930, boulevard Sacré-Coeur, Dolbeau, (Roberval), Québec.Téléphone: 276-2010.code 418.57553-0 Cité de Saint-Jérôme Comté de Prévost Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumission pour obligations » seront reçues par le soussigné Bruno Martin, greffier, Hôtel de ville, 280, rue Labelle, Cité de St.Jérôme, comté de Prévost, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mercredi, le 26 juin 1974, pour l'achat de $1,904,000 d'obligation de la cité de St-Jérôme, comté de Prévost, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $207,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Louis-Hémon Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: January 24, 1973 \u2014 $620,000 \u2014 construction of a comprehensive school complex in Dolbeau; August 29, 1973 \u2014 $1,460,000 \u2014 construction of a comprehensive school complex in Mistassini.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held at 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, June 26, 1974, at Notre-Dame-des-Anges School, Mistassini, Countv of Roberval, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Dolbeau, (County of Roberval), June 3, 1974.André Perron, Director-General.Administration Office, 930 Sacré-Coeur Boulevard, Dolbeau, (Roberval), P.Q.Telephone: 276-2010, code 418 57553 City of St.Jérôme County of Prévost Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Bruno Martin, City Clerk, at the City Hall, 280 Labelle Street, City of St.Jérôme, County of Prévost, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., on Wednesday, June 26, 1974, for the purchase of a bond issue of $1,904,000 for the City of St.Jérôme, County of Prévost, dated July 15, 1974, and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 juin 1971,, 106' année, n° 23 4343 ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,904,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975.$24,000 15 07 1976.26,000 15 07 1977.28,000 15 07 1978.31,000 15 07 1979.33,000 15 07 1980.35,000 15 07 1981.38,000 15 07 1982.41,000 15 07 1983 .44,000 15 07 1984.48,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $111,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéance excluant l'échéance du 15 juillet 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 juillet 1994 au montant de $907,000 comprend un solde de $804,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 07 1995.856,000 15 07 1996.60,000 15 07 1997.65,000 15 07 1998.70,000 15 07 1999.75,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15, 1974.Redemption table \u2014 $1,904.000 \u2014 20-years Date Capital 15 07 1985 .8 52,000 15 07 1986.56,000 15 07 1987 .61,000 15 07 1988.66,000 15 07 1989.71,000 15 07 1990.76,000 15 07 1991.82,000 15 07 1992.89,000 15 07 1993.96,000 15 07 1994 .907,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than 8111,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemptions, excluding the maturity of July 15, 2004 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of July 15.1994 in the amount of $907,000 includes a balance of 8804,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 07 2000.S 81,000 15 07 2001.88,000 15 07 2002.95,000 15 07 2003.103,000 15 07 2004.111,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure. 4344 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $907,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de d'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéance apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de St-Jérôme s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: C-752 \u2014 $250.000 \u2014 aqueduc et égouts: C-758 \u2014 $249,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; C-759 \u2014 $227,000 \u2014 achat et transformation d'équipement; C-762 \u2014 $140,000 \u2014 projet municipal d'habitation; C-780 \u2014 $60,000 \u2014 aqueduc et égouts; C-785 \u2014 $111,000 \u2014 divers travaux; C-786 \u2014 $225,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; C-787 \u2014 $50,000 \u2014 voirie; C-792 \u2014 $80,000 \u2014 achat d'équipeuieut; C-793 \u2014 $512,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 7.30 heures du soir, mercredi, le 26 juin 1974, Hôtel de ville, 280, rue Labelle, cité de St-Jérôme, comté de Prévost, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute m aucune des soumissions.Saint-Jérôme (Comté de Prévost), ce 30 mai 1974.Le greffier, Bruno Martin'.Hôtel de ville, 280, rue Labelle, Cité de St-Jérôme, Comté de Prévost, P.Q.Téléphone: 436-1511, code 514 57504-o Ville de St-Césaire Comté d'Iberville Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription < Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Pierre Despars, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 1111.ave Saint-Paul, St-Césaire, comté de Rouville, P.Q.jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, le 27 juin 1974, pour Pachat de $439,500 d'obligations de la ville de St-Césaire, comté d'Iberville, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellemcnt les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $907,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of St.Jérôme agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: C-752 \u2014 $250,000 \u2014 waterworks, sewers; C-758 \u2014 $249,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; C-759 \u2014 $227,000 \u2014 purchase and alteration of equipment; C-762 \u2014 $140,000 \u2014 municipal housing project; C-780 \u2014 $60,000 \u2014 waterworks and sewers; C-785 \u2014 $111,000 \u2014 miscellaneous works; C-786 \u2014 $225,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; C-787 \u2014 $50,000 \u2014 roads; C-792 $80,000 \u2014 purchase of equipment; C-793 \u2014 $512,000 \u2014 waterworks, sewers and roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, to be held on Wednesday, June 26, at 7:30 o'clock p.m.at the City Hall, 280 Labelle Street, City of St.Jérôme, County of Prévost, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Jérôme (County of Prévost), May 30, 1974.Bruno Martin, City Clerk.Town Hall, 280 Labelle Street, City of St.Jérôme (Prévost) P.Q.Telephone: 436-1511, code 514 .57504 Town of St.Césaire County of Iberville Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned.Pierre Despars, Secretary-Treasurer, at the Town Hall.1111 St.Paul Ave., St.Césaire, County of Rouville, P.Q.until 8:00 o'clock p.m., on Thursday, June 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $439,500, for the Town of St.Césaire, County of Rouville, dated July 15, 1974, and redeemable serially from July 15, 1975, to July 15, 1994, inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15th 1974. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° 23 4345 Tableau d'amortissement \u2014 $439,500 \u2014 20 ans Date Capital 15 07 1975.$11,500 15 07 1976.13,000 15 07 1977.14,000 15 07 1978.15,000 15 07 1979.16,000 15 07 1980.17,000 15 07 1981.18,000 15 07 1982.20,000 15 07 1983 .22,000 15 07 1984 .24,000 En plus, les modalités suivantes seulemen t seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $40,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 juillet 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $40,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 juillet de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de St-Césaire s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 283 \u2014 $66,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 356 \u2014 $373,000 \u2014 voirie, aqueduc et égouts.Redemption table \u2014 $439,600 \u2014 20 years Date Capital 15 07 1985.$17,000 15 07 1986.18,000 15 07 1987.20,000 15 07 1988.23,000 15 07 1989.25,000 15 07 1990.27,000 15 07 1991.30,000 15 07 1992.33,000 15 07 1993.36,000 15 07 1994.40,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $40,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of July 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $40,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on July 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Césaire agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after July 15,1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 283 \u2014 $66,500 \u2014 loan renewal; 356 \u2014 $373,000 \u2014 roads, waterworks and sewers. 4346 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106.No.S3 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, jeudi, le 27 juin 1974, Hôtel de ville.1111.ave St-Paul, St-Césaire, comté de Rouville, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissios.St-Césaire (Comté de Rouville), ce 31 mai 1974.Le secrétaire-trésorier, Pierre Despars.Hôtel de ville, 1111, ave St-Paul.St-Césaire, (Rouville), Québec.Téléphone: 469-3108.code 514.57555-o Ville de Saint-Gabriel Comté de Berthier Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Raymond Gagnon, secrétaire-trésorier.Hôtel de ville, 45, Beausoleil, Saint-Gabriel, comté de Berthier, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, jeudi, le 27 juin 1974, pour l'achat de 8166,000 d'obligations de la ville de Saint-Gabriel, comté de Berthier, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1989 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $166,000 \u2014 15 ans Date Capital 15 07 1975.8 5,500 15 07 1976.6,500 15 07 1977.7,000 15 07 1978.7,500 15 07 1979.8,000 15 07 1980.8,500 15 07 1981.9,500 15 07 1982.10,500 De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance 10 ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des 2 termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or one of its committees, as the case may be, to be held on Thursday, June 27, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 1111 St.Paul Avenue, St.Césaire, County of Rouville, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Césaire (County of Rouville), May 31, 1974.Pierre Despars, Secretary-Treasurer.Town Hall, 1111 St.Paul Avenue, St.Césaire, (Rouville), Québec., Telephone: 469-3108, code 514.57555 Town of St.Gabriel County of Berthier Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Raymond Gagnon, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 45 Beausoleil, St.Gabriel, County of Berthier, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Thursday, June 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $166,000 for the Town of St.Gabriel, County of Berthier, dated July 15, 1974 and redeemable serially from July 15.1975 to July 15, 1989 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%.payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15, 1974.Redemption table \u2014 9166,000 \u2014 15 years Date CapiUl 15 07 1983.$11,500 15 07 1984.12,000 15 07 1985.13,000 15 07 1986.14,500 15 07 1987.16,000 15 07 1988.17,000 15 07 1989.19,000 Moreover, tenders may be sent and they will be taken into consideration for 10-year short-term bonds.However, tenders should comprise one only of the two terms.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106- année, n° 23 4347 Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Saint-Gabriel s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro C.V.49 \u2014 $166,000 \u2014 consolidation de déficit.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue jeudi, le 27 juin 1974, à 8 heures du soir, Hôtel de ville, 45, Beausoleil, Saint-Gabriel, comté de Berthier, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Gabriel (Comté de Berthier), ce 4 juin 1974.Le secrétaire-trésorier, Raymond Gagnon.Hôtel de ville, 45, rue Beausoleil, Saint-Gabriel, (Berthier), Québec.Téléphone: 835-2212, code 514.57561-0 Commission scolaire régionale North-Island Siège social: 4335, boulevard Notre-Dame, Chomedey, (Laval), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription < Soumissions pour obligations 9 seront reçues par le soussigné Mark Holmes, m.d., directeur général, Centre administratif, 4335, boulevard Notre-Dame, Chomedey, comté de Laval, P.Q., jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi, et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, École Western Laval, 5075 ouest, rue du Souvenir, Chomedey, comté de Laval, P.Q., jeudi, le 27 juin 1974, pour l'achat de $1,041,000 d'obligations de la commission scolaire régionale North-Island, datées du 15 juillet 1974 et remboursables en série du 15 juillet 1975 au 15 juillet 1987 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 15 janvier et 15 juillet de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 juillet 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $1,041,000 \u2014 13 ans Date Capital 15 07 1975.$ 48,500 15 07 1976.53,000 15 07 1977 .57,000 15 07 1978 .61,500 15 07 1979.66,500 15 07 1980 .71,500 15 07 1981.77,000 Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of St.Gabriel agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number C.V.49 \u2014 $166,000 \u2014 consolidation of deficit.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Thursday, June 27, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Town Hall, 45 Beausoleil, St.Gabriel, County of Berthier, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Gabriel (County of Berthier), June 4, 1974.Raymond Gagnon, Secretary-Treasurer.Town Hall, 45 Beausoleil Street, St.Gabriel, (Berthier), Québec.Telephone': 835-2212, code 514.57561 The Norh Island Regional School Board Head Office: 4335, Notre-Dame Blvd.Chomedey, Laval, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\", will be received by the undersigned, Mark Holmes, m.d., Director-General, at the Administration Centre, 4335 Notre-Dame Boulevard, Chomedey, County of Laval, P.Q., until »:30 o'clock p.m., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at Western Laval School, 5075 Du Souvenir Street West, Chomedey, County of Laval, P.Q., on Thursday, June 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $1,041,000 for the North Island Regional School Board, dated July 15, 1974 and redeemable serially from July 15, 1975 to July 15, 1987 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%, nor more than 10%, payable semiannually on January 15th and July 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from July 15,1974.Redemption table \u2014 $1,041,000 \u2014 13 years Date Capital 15 07 1982.$ 83,000 15 07 1983 .89,500 15 07 1984.97,000 15 07 1985.104,000 15 07 1986.111,500 15 07 1987.121,000 4348 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.June 8.1974.Vol.106, No.23 La commission scolaire régionale North-Island, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachctablcs par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale North-Island s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 juillet 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 4 janvier 1968 \u2014 $1.001,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 22 avril 1974 \u2014 $40,000 \u2014 frais de refinancement.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue le 27 juin 1974, à 8.00 heures du soir.École Western Laval, 5075 ouest, rue du Souvenir, Chomedey, comté de Laval.P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Chomedey (Comté de Laval), ce 4 juin 1974.Le directeur général.Mark Holmes, m.d.Centre administratif, 4335, boulevard Notre-Dame, Chomedey, (Laval), Québec.Téléphone: 688-4020, code 514.57560-o The North Island Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The North Island Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon from and after July 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: January 4, 1968 \u2014 $1,001.000 \u2014 loan renewal; April 22, 1974 \u2014 $40,000 \u2014 refinancing costs.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on June 27, 1974, at 8:00 o'clock p.m.at Western Laval School.5075 Du Souvenir Street West, Chomedey, County of Laval, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Chomedey (County of Laval), June 4, 1974.Mark Holmes, m.d., Director-General.Administration Centre, 4335 Notre-Dame Boulevard, Chomedey, (Laval), P.Q.Telephone: 688-4020, code 514.57560 Ministère des transports Department of Transport Avis Les chemins ci-après désignés ne seront plus, à l'avenir, entretenus par le ministère des transports.Comté d'Arthabaska: Dans la municipalité de Warwick canton : Notice The roads hereinafter described shall no longer be maintained by the Department of Transport.County of Arthabaska: In the Municipality of Warwick Township: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4349 L'ancienne route 5, vis-à-vis des lots P-33 et P-35 sur une longueur de 600 pieds.Dans la municipalité de Sainte-Victoire-d'Artha-baska paroisse: L'ancien chemin du Xème rang Est et Ouest vis-à-vis du lot 706 sur une longueur de 1,100 pieds et vis-à-vis du lot 26-B sur une longueur de 700 pieds.Comté de Beauce: Dans la municipalité de Sainte-Clothilde paroisse: L'ancien chemin du rang IX (271) vis-à-vis des lots P-25A.P-24C, P-24B, P-24A sur une longueur de 2,580 pieds.Comté de Duplessis: Dans la municipalité de Port-Cartier ville: Le chemin du Parc de l'intersection sud jusqu'à l'intersection nord avec le nouveau chemin sur une longueur de 1,670 pieds.Comté de Drummond: Dans la municipalité de Kingsey canton: L'ancien chemin de Richmond vis-à-vis des lots 12A et 11B sur une longueur de 610 pieds.Dans la municipalité de Wickham : L'ancienne route 13 vis-à-vis des lots P-424 sur une longueur de 1,880 pieds et vis-à-vis des lots P-424, P-425 et P-361 sur une longueur de 2,200 pieds.Comté de Beauce: (Frontenac) Dans la municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce: Trois parties de l'ancienne route 216.vis-à-vis des lots P-21-B, P-21-C, P-22-A, P-22-B, P-22-C sur une longueur de 1,570 pieds; vis-à-vis des lots P-22-C, P-22-D, P-23-A sur une longueur de 1,290 pieds; vis-à-vis des lots P-24, P-24-A, P-24-B, P-24-C, P-25-A sur une longueur de 1,750 pieds.Dans la municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce: Cinq parties de l'ancienne route 216 vis-à-vis des lots P-324, P-325, P-413, P-435, P-436 sur une longueur de 1,170 pieds; vis-à-vis des lots P-437, P-438, P-413 sur une longueur de 635 pieds; vis-à-vis des lots P-438, P-439-A, P-439 sur une longueur de 1,550 pieds; vis-à-vis des lots P-443 à P-455 sur une longueur de 3,175 pieds; vis-à-vis du lot P-413 ancien raccordement au chemin Haut Ste-Anne sur une longueur de 290 pieds.Comté de Gaspè-Nord: Dans la municipalité de Saint-Joachim-de-Tourelle paroisse : L'ancienne route 2 (132) vis-à-vis des lots 5-B, 4-B, 4-A et 3-C sur une longueur de 1,000 pieds et vis-à-vis des lots 3-C et 3-D sur une longueur de 400 pieds.Dans la municipalité de Gaspé ville (Haldemand) : Deux parties de l'ancienne route No 6 vis-à-vis des lots 2,3, 4, 5 et 6 sur une longueur de 3,950 pieds et vis-à-vis du lot 2 sur une longueur de 930 pieds.Former Highway No.5, facing lots Pt-33 and Pt-35 over a distance of 600 feet.In the Municipality of Ste.Vicloire-d'Arthabaska Parish: The former road of the 10th Range East and West facing lot 706 over a distance of 1,100 feet and facing lot 26-B, over a distance of 700 feet.County of Beauce: In the Municipality of Ste.Clothilde Parish: The former road of Range IX (271) facing lots Pt- 25-A, Pt-24-C, Pt-24-B, Pt-24-A over a distance of 2,580 feet.County of Duplessis: In the Municipality of Port-Cartier, Town : Park Road from the south intersection to the north intersection with the new road over a distance of 1,670 feet.County of Drummond: In the Municipality of Kingsey Township: The former Richmond Road facing lots 12-A and 11-B over a distance of 610 feet.In the Municipality of Wickham: Former Highway No.13 fronting lots Pt-424 over a distance of 1,880 feet and facing lots Pt-424, Pt-425 and Pt-361 over a distance of 2,200 feet.County of Beauce: (Frontenac) In the Municipality of St.Elzéar-de-Beauce: Three parts of former Highway No.216, facing lots Pt-21-B, Pt-21-C, Pt-22-A, Pt-22-B, Pt-22-C over a distance of 1,570 feet; facing lots Pt-22-C, Pt-22-D, Pt-23-A over a distance of 1,290 feet; facing lots Pt-24, Pl-24-A, Pt-24-B, Pt-24-C, Pt-25-A over a distance of 1,750 feet.In the Municipality of St.Elzéar-de-Beauce: Five parts of former Highway No.216 facing lots Pt-324, Pt-325, Pt-413, Pt-435, Pt-436 over a distance of 1,170 feet; facing lots Pt-437, Pt-438, Pt-413 over a distance of 635 feet; facing lots Pt-438, Pt-439-A, Pt-439 over a distance of 1,550 feet: facing lots Pt-443 to Pt-455 over a distance of 3,175 feet; facing lot Pt- 413 former junction with Haut Ste.Anne Road over a distance of 290 feet.County of Gaspé-North: In the Municipality of St.Joachim-de-Tourelle Parish: Former Highway No.2 (132) facing lots 5-B, 4-B, 4-A and 3-C over a distance of 1,000 feet and facing lots 3-C and C-D over a distance of 400 feet.In the Municipality of Gaspé City (Haldemand) : Two parts of former Highway No.6 fronting lots 2, 3, 4, 5 and 6 over a distance of 3,950 feet and facing lot 2 over a distance of 930 feet. 4350 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.38 Comté de Jonquière: Dans la municipalité de Kénogami canton: Deux parties de l'ancien chemin Pibrac vis-à-vis des lots P-6 et P-7 sur une longueur de 700 pieds et vis-à-vis du lot P-6 sur une longueur de 1,650 pieds.Comté de L'Islet: Dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli: L'Ancien chemin du rang II ouest vis-à-vis des lots P-360, P-356, P-355 sur une longueur de 495 pieds et vis-à-vis des lots P-424 à P-444 inclus sur une longueur de 6,850 pieds; L'ancien chemin du rang II est vis-à-vis des lots P-78 à P-54 inclus et P-477 à P-499 inclus sur une longueur de 5,780 pieds.Comté de St-Hyacinthe: Dans la municipalité de la Présentation paroisse: L'ancien chemin du rang Salvail vis-à-vis des lots P-164, P-166, P-167, 168 et P-165 sur une longueur de 610 pieds.Dans la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine paroisse : L'ancien chemin du 4e rang vis-à-vis des lots 165, 258 et 257 sur une longueur de 500 pieds.Dans la municipalité de Saint-Charles paroisse: Vis-à-vis du lot 283 sur une longueur de 160 pieds.Comté d'Yamaska: Dans la municipalité de Saint-Michel-d'Yamaska paroisse : L'ancien chemin Bord-de-l'Eau vis-à-vis des lots 199, P-216, P-217, P-213 sur une longueur de 1,900 pieds.Québec, le 9 mai 1974.County of Jonquière: In the Municipality of Kénogami Township: Two parts of the former Pibrac Road facing lots Pt-6 and Pt-7 over a distance of 700 feet and facing lot Pt-6 over a distance of 1,650 feel.County of L'Islet: In the Municipality of St.Jean-Port-Joli : The former road of Range II West facing lots Pt-360, Pt-356, Pt-355 over a distance of 495 feet and facing lots Pt-424 to Pt-444 inclusive, over a distance of 6,850 feet; The former road of Range II facing lots Pt-78 to Pt-54 inclusive, and Pt-477 to Pt-499 inclusive, over a distance of 5,780 feet.County of St.Hyacinthe: In the Municipality of Présentation Parish: The former road of Salvail Range facing lots Pt-164, Pt-166, Pt-167, 168 and Pt-165 over a distance of 610 feet.In the Municipality of Ste.Marie-Madeleine Parish: The former road of the Fourth Range facing lots 165, 258 and 257 over a distance of 500 feet.In the Municipality of the St.Charles Parish: Facing lot 283 over a distance of 160 feet.County of Yamaska: In the Municipality of St.Michel-d'Yamaska Parish : The former Bord-de-1'Eau Road fronting lots 199, Pt-216, Pt-217, Pt-213 over a distance of 1,900 feet.57547-0 Le ministre des transports, Raymond Mailloux.Québec, May 9, 1974.57547 Raymond Mailloux, Minister of Transport.Sociétés agricoles et laitières Farmers' and Dairymen's Associations Cercle d'amélioration du bétail de Haut Saint-Maurice Avis est donné que, en vertu de l'arrêté en conseil No 186-74 du 16 janvier 1974, le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « CERCLE D'AMELIORATION DU BETAIL DE HAUT SAINT-MAURICE », avec siège social à La Croche, dans le comté de Cham-plain, conformément à la Loi des sociétés agricoles et laitières (S.R.Q.1964, chapitre 116).Daté au bureau du ministre, le 27 mai 1974.57490-o Le sous-ministre de l'agriculture, Gaétan Lussieii.Cercle d'amélioration du bétail de Haut Saint-Maurice Notice is given that, pursuant to Order in Council No.186-74 dated January 16th 1974, the Lieutenant-Governor in Council has authorized the formation of a farmers' and dairymen's association under the name of \"CERCLE D'AMELIORATION DU BETAIL DE HAUT ST-MAURICE\", with head office located at La Croche, in the County of Champlain, under the Farmers' and Dairymen's Associations Act (R.S.Q.1964, Chapter 116).Dated at the Minister's office.May 27th, 1974.57190 Gaétan Lussier, Deputy Minister of Agriculture. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4351 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu > (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.ITT \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 4352 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.28 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (A) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking \"Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 à M 002000 Q 000001 à Q 001000 M 100001 à M 103000 Q 100001 à Q 102000 M 200001 à M 210000 Q 200001 à Q 205000 M 300001 à M 303000 Q 300001 à Q 302000 M 400001 à M 402000 Q 400001 à Q 401000 M 500001 à M 504000 Q 500001 à Q 503000 M 600001 à M 601000 Q 600001 à Q 600500 M 700001 à M 700500 Q 700001 à Q 700500 M 800001 à M 800500 Q 800001 à Q 800500 M 900001 à M 900500 Q 900001 à Q 900500 omT ~ M°?tréaI transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Quebec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers rtOT ~~ ^°,n_tréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students tjfb \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab nri?_ M°.IJtréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking W « Un immeuble ayant front sur l'avenue Labelle en la ville de Longueuil contenant en superficie cinq mille quatre cent vingt-sept pieds carrés (5427 p.c.) et composé du lot de terre connu et désigné comme étant la subdivision officielle numéro cinq cent vingt-six (526) du lot originaire numéro cent trente-cinq (135-526) au cadastre officiel de la Paroisse de St-Antoine-de-Longueuil ; Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes constructions, circonstances et dépendances y érigées, notamment une maison actuellement en voie de construction et portant les numéros 2315, 2317 et 2319 de ladite avenue Labelle et dont le mur nord-ouest est mitoyen avec le mur sud-est de la maison portant les numéros 2305, 2307 et 2309 de ladite avenue Labelle; » « Un immeuble ayant front sur l'avenue Labelle en la ville de Longueuil contenant en superficie cinq mille quatre cent vingt-sept pieds carrés (5427 p.c.) et composé du lot de terre connu et désigné comme étant la subdivision officielle numéro cinq cent vingt-sept (527) du lot originaire numéro cent trente-cinq (135- 527) au cadastre officiel de la Paroisse de St-Antoine-de-Longueuil; Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes constructions, circonstances et dépendances y érigées notamment une maison actuellement en voie de construction et portant les numéros 2325, 2327 et 2329 de ladite avenue Labelle et dont le mur sud-est est par les présentes établi mitoyen par destination de père de famille dans toutes ses hauteurs, épaisseur, longueur, de même que la lisière de terre sur laquelle il repose avec le mur nord-ouest de la maison située aux numéros 2335, 2337 et 2339 deladite avenue Labelle; » « Un immeuble ayant front sur l'avenue Labelle en la ville de Longueuil contenant en superficie cinq mille quatre cent vingt-sept pieds carrés (5427 p.c.) et composé du lot de terre connu et désigné comme étant la subdivision officielle numéro cinq cent vingt-huit (528) du lot originaire numéro cent trente-cinq (135- 528) au cadastre officiel de la Paroisse de St-Antoine-de-Longueuil ; Tel que le tout se trouve actuellement avec toutes constructions, circonstances et dépendances et y érigées, notamment une maison actuellement en voie de construction et portant les numéros 2335, 2337 et 2339 de ladite avenue Labelle, et dont le mur nord-ouest est mitoyen avec le mur sud-est de la maison portant les numéros 2325, 2327, 2329 de ladite avenue Labelle.» As the whole now subsists with all buildings, appurtenances and dependencies erected thereon, particularly a house presently under construction bearing numbers 2305, 2307, 2309 on said Labelle Avenue and of which the southeast wall is hereby constituted as common, by an agreement between the owners, on its every height, thickness, length, as well as the strip of land on which it rests, with the northwest wall of the house located at numbers 2315, 2317 and 2319 on said Labelle Avenue;\" \"An immoveable fronting on Labelle Avenue in the City of Longueuil, covering an area of five thousand four hundred twenty-seven square feet (5,427 sq.ft.) and comprising the piece of land known and described as being the official subdivision number five hundred twenty-six (526) of original lot number one hundred thirty-five (135-526) on the official cadastre for the Parish of St.Antoine-de-Longueuil; As the whole now subsists with all buildings, appurtenances and dependencies erected thereon, particularly a house presently under construction and bearing numbers 2315, 2317 and 2319 on said Labelle Avenue and of which the northwest wall is common with the southeast wall of the house bearing numbers 2305,2307 and 2309 on said Labelle Avenue;\" \"An immoveable fronting on Labelle Avenue in the City of Longueuil covering an area of five thousand four hundred twenty-seven square feet (5,427 sq.ft.) and comprising the piece of land known and described as being the official subdivision number five hundred twenty-seven (527) of original lot number one hundred thirty-five (135-527) on the official cadastre for the Parish of St.Antoine-de-Longueuil; As the whole now subsists with all buildings, appurtenances and dependencies erected thereon, particularly a house presently under construction and bearing numbers 2325, 2327 and 2329 on said Labelle Avenue and of which the southeast wall is hereby constituted as common, by an agreement between the owners on its every height, thickness, length, as well as the strip of land on which it rests, with the northwest wall of the house located at numbers 2335, 2337 and 2339 on said Labelle Avenue;\" \"An immoveable fronting on Labelle Avenue in the City of Longueuil, covering an area of five thousand four hundred twenty-seven square feet (5,427 sq.ft), and comprising the piece of land known and described as being the official subdivision number five hundred twenty-eight (528) of original lot number one hundred thirty-five (135-528) on the official cadastre for the Parish of St.Antoine-de-Longueuil; As the whole now subsists with all buildings, appurtenances and dependencies erected thereon, particularly a house presently under construction and bearing numbers 2335, 2337 and 2339 on said Labelle Avenue, and of which the northwest wall is common with the southeast wall of the house bearing numbers 2325, 2327, 2329 on said Labelle Avenue.\" 4368 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8.1974, Vol.106, No.S3 Pour être vendu séparément, au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, 201.Place Charles Lemoyne, Édifice Montval, à Longueuil, P.Q., le DIXIÈME jour de JUILLET 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 30 mai 1974.57531-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( T >ASS U R A N C E VIE Cour Supérieure, ) DESJARDINS, corpo- No 200-05-000773-742.\"j ration légalement constituée.\\ ayant son siège social au 200 Avenue des Commandeurs, Lévis, district de Québec, versus ROBERT FLEURY, organisateur syndical, domicilié et résidant au 147 rue St-Raoul, Beauport, district de Québec, et LE REGISTRATEUR, division d'enregistrement de Québec.« Un immeuble étant et comprenant: a) Un lopin de terre connu et désigné comme étant la subdivision sept du lot originaire numéro sept cent quatre-vingt-dix-neuf (799-7) du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, division d'enregistrement de Québec.b) Un lopin de terre connu et désigné comme étant la subdivision six du lot originaire numéro sept cent quatre-vingt-seize (796-6) du cadastre officiel de la paroisse de Beauport, division d'enregistrement de Québec; avec maison dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, P.Q., le VINGT-TROISIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 3 juin 1974.57545-o Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:/ \"X/fARCEL MARTINEAU, Cour Provinciale,) LVX entrepreneur électricien, fai- No 103-658.J sant affaires à 716 Commerciale, (Lévis, versus LES AMEUBLEMENTS COL CAN LTÉE.corporation légale ayant son siège social au 134, rue Du Sault, Saint-Romuald, comté de Lévis et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Lévis.« Lot 115-A-l du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Henri, comté de Lévis, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Lévis, 113, St-Georges Ouest, Lévis, comté de Lévis, le VINGT-DEUXIEME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 3 juin 1974.57530-o To be sold separately, at the County of Chambly Registry Office, 201 Place Charles Lemoyne, Montval Building, in Longueuil, P.Q., on the TENTH day of JULY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, May 30, 1974.57531 QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, to wit: fT 'ASSURANCE VIE Superior Court, ) *-< DESJARDINS, a cor-No.200-05-000773-742.) poration legally incorporated, \\ having its head office at 200 Des Commandeurs Avenue, Levis, District of Québec, versus ROBERT FLEURY, union organiser, domiciled and residing at 147 St.Raoul Street, Beauport, District of Québec, and THE REGISTRAR, Québec Registration Division.\"An immoveable being and comprising: (a) A plot of land known and described as being subdivision seven of original lot number seven hundred ninety-nine (799-7) on the official cadastre for the Parish of Beauport, Québec Registration Division.(6) A plot of land known and described as being subdivision six of original lot number seven hundred ninety-six (796-6) on the official cadastre for the Parish of Beauport, Québec Registration Division; with houses erected thereon, appurtenances and dependancies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, P.Q., on the THIRTY-THIRD day of JULY 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 3, 1974.57545 Fieri Facias de Terris Québec, to wit : ( \"KyTA R C E L MARTINEAU, Provincial Court, J -LVA electrical contractor, having No.103-658.J its place of business at 716 Com-' merciale, Levis, versus LES AMEUBLEMENTS COL CAN LTÉE, a legal corporation having its head office at 134 Du Sault Street, St.Romuald, County of Levis, and THE REGISTRAR for the Levis Registration Division.\"Lot 115-A-l on the official cadastre for the Parish of St.Henri, County of Levis, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Levis Registration Office, 113 St.Georges West, Levis, County of Levis, on the TWENTY-SECOND day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 3, 1974.57530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n\" 23 4369 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: /T ES HUILES CARTIER Cour Provinciale, ) ^ LTEE, corps politique No 200-02-003085-745.') légalement constitué ayant \\ une place d'affaires à 901, Cardinal Rouleau, Québec, contre GUY ROBICHAUD, domicilié et résidant à 637, rue Notre-Dame, Notre-Dame-des-Laurentides, district de Québec.« Une partie du lot numéro quatre-vingt-seize (96) non subdivisé du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, situé dans la ville de Notre-Dame-des-Laurentides et décrite comme suit: de figure irrégulière, bornée au sud-est par la rue Georges Muir un chemin privé et les propriétés de Raymond Morin, Conrad Robicbaud, Lucien Carbonneau et L.Mainguy, au sud-ouest par le lot 95 non subdivisé, un chemin privé et la propriété de Conrad Robichaud, au nord-ouest par la propriété de E.Villeneuve et nord-est par la propriété de Jeanne Turcotte, de Dame T.Robichaud, Jean G.Corriveau, Lucien Carbonneau, Maurice Duval, L.Mainguy et Edgard Payette.Cette partie contient une superficie de dix arpents carrés (10 arp.car.) plus ou moins mesure anglaise, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le VINGT-QUATRIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 3 juin 1974.57529-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: l T ES HUILES CARTIER Provincial Court, ) *-> LTEE, a body politic No.200-02-003085-745.1 legally incorporated'having a ' place of business at 901 Cardinal Rouleau, Québec, versus GUY ROBICHAUD, domiciled and residing at 637 Notre-Dame street, Notre-Dame-des-Laurentides, District of Québec.\"A part of lot number ninety-six (96) unsubdivided, on the official cadastre for the Parisb of Charlesbourg, located in the Town of Notre-Dame-des-Laurentides and described as follows: of regular configuration, bounded on the southeast by Georges-Muir Street, a private road and the properties of Raymond Morin, Conrad Robichaud, Lucien Carbonneau and L.Mainguy, on the southwest by lot number 95 unsubdivided, a private road and the property of Conrad Robichaud, on the northwest by the property of E.Villeneuve and on the northeast by the property of Jeanne Turcotte, of Mrs.T.Robichaud, Jean G.Corriveau, Lucien Carbonneau, Maurice Duval, L.Mainguy and Edgard Payette.This part has an area of ten square arpents (10 sq.arp.) more or less, English measure, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, in Québec, on the TWENTY-FOURTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 3, 1974.57529 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( COCIETE CENTRALE Cour Supérieure, ) O D'HYPOTHEQUES ET No 200-05-000755-74.1 DE LOGEMENT, corpora-\\ tion légalement constituée, ayant sa principale place d'affaires en la ville d'Ottawa, province d'Ontario, et une succursale en la cité de Sil-lery, district de Québec contre ROGER LEHOUIL-LIER, 1619, Moselle, Orsainville, district de Québec, et RAYMOND ROY, en sa qualité de registrateur de la division d'enregistrement de la ville de Québec, mis en cause.« La subdivision numéro deux cent quarante-trois du lot originaire numéro six cent soixante (660-243) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, et avec toutes les servitudes actives et passives pouvant affecter le susdit immeuble.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le VINGT-DEUXIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault, Québec, le 3 juin 1974.57546-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: ( CENTRAL MORTGAGE Superior Court, ) V-l AND HOUSING COR-No.200-05-000755-74.1 PORATION, a corporation \\ legally incorporated, having its principal place of business in the City of Ottawa, Province of Ontario, and a branch in the City of Sillery, District of Québec, versus ROGER LEHOUILLIER, 1619 Moselle, Orsainville, District of Québec, and RAYMOND ROY, in his capacity as Registrar for the City of Québec Registration Division, mis en cause.\"Subdivision number two hundred forty-three of original lot number six hundred sixty (660-243) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg.With the buildings erected thereon, ap;r .cenances and dependencies, and with all active and passive servitudes which may affect the aforesaid immoveable.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, on the TWENTY-SECOND day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 3, 1974.57546 4370 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.S3 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias De Bonis el De Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de St-François l pHAUFFAGE LAURENTIEN INC., No 37-301.s V>* corps politique légalement consti-' tué, faisant affaires à 2560 ouest, rue King, Sherbrooke, district de St-François, demanderesse, vs J.AIMÉ PERRON INC., corps politique légalement constitué de Coaticook, district de St-François, défenderesse, et ANDRÉ TROTTIER, en sa qualité de syndic à la faillite de J.Aimé Perron Inc., et LE REGISTRATEUR de la division de Sherbrooke, mis en cause.« Les lots 160-7-1 et 160-6-2 du canton d'Orford, avec bâtisse dessus construite.» Pour être vendus en bloc au bureau du shérif, 191, rue Palais, Sherbrooke, Que., MARDI, le NEUVIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures dans la matinée.(Sceau) Bureau du Shérif, Palais de Justice, Le shérif adjoint, Sherbrooke, P.Q., Jean-Guy Bisson.Ce 29 mai 1974.57492-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Saint-François t TRUST ROYAL, corpora-No 450-05-000171-74.< A tion ayant un bureau et ' un établissement d'affaires au 25 nord, rue Wellington, en la cité de Sherbrooke, district de Saint-François, province de Québec, demanderesse, vs BERTRAND PROVENCHER, entrepreneur résidant au 1600, rue Larocque, en la cité de Sherbrooke, district de Saint-François, province de Québec, défendeur, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de la division de Sherbrooke, mis en cause.« La subdivision numéro quatre cent quarante-huit du lot originaire numéro quinze A (15A-448) dans le rang sept aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton Ascot.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le numéro 1600, rue Larocque, Sherbrooke.» Pour être vendu au bureau du shérif, 191, rue Palais, Sherbrooke, Québec, JEUDI le ONZIÈME jour de JUILLET 1974, à DIX heures dans la matinée.(Sceau) Bureau du Shérif, Palais de Justice, Le shérif adjoint.Sherbrooke, (Québec), Jean-Guy Bisson.Ce 29 mai 1974.57491 SAINT-FRANÇOIS Fieri Facias De Bonis et De Terris Canada \u2014 Province de Québec Provincial Court \u2014 District of Saint-François l pHAUFFAGE LAURENTIEN INC., No.37-301.< W a body politic and legally încor-porated, carrying on business at 2560 King Street West, Sherbrooke, District of St.François, plaintiff, vs J.AIMÉ PERRON INC., a body politic and legally incorporated, of Coaticook, District of Saint-François, defendant, and ANDRÉ TROTTIER, in his capacity as trustee in the bankruptcy of J.Aimé Perron Inc., and THE REGISTRATOR for the Sherbrooke Division, mis en cause.\"Lots 160-7-1 and 160-6-2 in the Township of Orford, with building erected thereon.\" To be sold \"en bloc\" at the Sheriff's Office, 191 Palais Street, Sherbrooke, Québec, on TUESDAY, the NINTH day of JULY 1974, at TEN o'clock in the morning.(Seal) Sheriff Office, Court of Justice, Jean-Guy Bisson, Sherbrooke, P.Q., Assistant Sheriff.May 29, 1974.57492 Fieri Facias de Terris Canada ¦\u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of St.François (THE ROYAL TRUST No 450-05-000171-74.< i- COMPANY, a corpora-V tion having an office and place of business in the City of Sherbrooke, District of St.Francis, Province of Québec at 25 Wellington Street North, plaintiff, tu BERTRAND PROVENCHER, contractor, of the City of Sherbrooke, District of St.Francis, Province of Québec, and therein residing at 1600 Larocque Street, defendant, and THE REGISTRAR, Sherbrooke Division Registry Office, mis en cause.\"Subdivision number four hundred forty-eight of original lot number fifteen A (15A-448) in Range Seven on the official plan and in the book of reference for the Township of Ascot.With buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, bearing number 1600 Larocque Street, Sherbrooke.\" To be sold at the Sheriff's Office, 191 Palais Street, Sherbrooke.P.Q., on THURSDAY, the ELEVENTH day of JULY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.(Seal) Sheriff's Office, Court House, Jean-Guy Bisson, Sherbrooke, (Québec), Assistant Sheriff.May 29, 1974.S7491-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106- année, n\" S3 4371 SAINT-HYACINTHE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Saint-Hyacinthe ( p A.C.REALTY LIMI-No 750-05-000081-74X v-*- TED, demanderesse, vs l GÉRARD ST-PIERRE, défendeur et LAURENT LANGEVIN, et LE REGISTRATEUR du bureau d'enregistrement de St-Liboire, mis en cause.« Un immeuble situé à St-Pie, comté de Bagot, désigné comme étant une partie du lot numéro six cent trois (Ptie 603) au cadastre de la paroisse de St-Pie, mesurant quarante-cinq pieds (45') de largeur sur une profondeur de quatre-vingts pieds (80'), le tout à la mesure anglaise et plus ou moins et borné comme suit: au sud-est, par l'avenue Salaberry, au nord-est par une partie du même lot appartenant à la succession Élizée Désau-tels ou représentants, au nord-ouest par le terrain appartenant à M.Philippe Beauregard ou représentants et au sud-ouest, par le lot 600 appartenant à M.Julien Plante.Avec une maison dessus érigée, circonstances et dépendances.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble.Pour être vendu au bureau d'enregistrement, division de Bagot, à Saint-Liboire, comté de Bagot, MERCREDI, le VINGT-QUATRIÈME jour du mois de JUILLET 1974, à QUATORZE heures.Bureau du Shérif, Le Shérif, Cour Supérieure, Michel Laroche.Saint-Hyacinthe, ce 29 mai 1974.57502-o TERREBONNE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Terrebonne / \\X/lVI' MARKSINC- corporation léga-Xo 66,158a VV lement constituée ayant son siège ' social et sa principale place d'affaires à Ste-Agathe-des-Monts dans les comté et district de Terrebonne, demanderesse, vs HOTEL BELMONT (1971) INC., corporation légalement constituée ayant son siège social et sa principale place d'affaires au 103, rue Principale à Ste-Agathe-des-Monts, dans les comté et district de Terrebonne, et CHARLES DESMARTEAU, courtier en immeubles de Boucherville dans le comté de Chambly et le district de Montréal et y demeurant au 414 boulevard Marie-Victorin, défendeurs.L'immeuble ci-après désigné en la possession de Hôtel Belmont (1971) Inc.: « Un emplacement situé en la ville de Ste-Agathe-des-Monts, dans Je troisième rang du Canton Beresford, faisant partie du lot de terre, figurant au cadastre officiel de la paroisse de Ste-Agathe-des-Monts, sous le numéro onze C (Ptic 11 C) et borné comme suit: au nord par la rue Principale et par les lots 11C-165, 11C- SAINT-H YACINTHE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of St.Hyacinthe l f-i A.C.REALTY LIMI-No.750-05-000081-74.-C TED, plaintiff, vs GÉ- ^ARD ST.PIERRE, defendant, and LAURENT LANGEVIN, and THE REGISTRAR for the St.Liboire Registry Office, mis en cause.\"An immoveable located in St.Pie, County of Bagot, described as being part of lot number six hundred and three (Part 603) on the official cadastre for the Parish of St.Pie, measuring forty-five feet (45') in width by eighty feet (80') in depth, the whole in English measure and more or less.Bounded as follows: on the southeast by Salaberry Avenue, on the northeast by a part of said lot belonging to the Elisée Désautels estate or representatives, on the northwest by the piece of land belonging to Mr.Philippe Beauregard or representatives, and on the southwest, by lot number 600 belonging to Mr.Julien Plante.With a building erected thereon, appurtenances and dependencies.As the whole now subsists with all active and passive, apparent or unapparent servitudes attaching to said building.\" To be sold at the Bagot Division Registry Office, in St.Liboire.County of Bagot, on WEDNESDAY, the TWENTY-FOURTH day of JULY, 1974, at TWO o'clock in the afternoon.Sheriff's Office, Michel Laroche, Superior Court, Sheriff.St.Hyacinthe, May 29, 1974.57502 TERREBONNE Canada \u2022\u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Terrebonne ( W/M.MARKS Inc., a corporation No.66,158a legally incorporated having its ' head office and its principal place of business in Ste.Agathe-des-Monts, County and District of Terrebonne, plaintiff, vs HOTEL BELMONT (1971) INC., a corporation legally incorporated having its head office and its principal place of business at 103 Principale Street, in Ste.Agathe-des-Monts, County and District of Terrebonne, and CHARLES DES-MARTEAU, real estate broker of Boucherville, in the County of Chambly and District of Montreal, residing therein at 414 Marie-Victorin Boulevard, defendants.The immoveable hereinafter described, belonging to Hotel Belmont (1971) Inc.: \"An emplacement located in the Town of Ste.Agathe-des-Monts, in the Third Range of the Township of Beresford, forming part of the piece of land shown on the official cadastre for the Parish of Ste.Agathe-des-Monts, as number eleven C (Pt.11 C) and bounded as follows: on the north by Principale Street and by lots 4372 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, June 8, 1974, Vol.106, No.23 163 et par une partie du lot 11C; au sud par la rue Larocque; à l'ouest par d'autres parties du lot 11C et à l'est par les lots 11C-162, 11C-163 et 11C-164; Cet emplacement mesure quarante-deux pieds et un dixième de pied (42.1') en front, le long de la rue Principale; soixante-douze pieds (72') aussi dans une ligne nord le long de la ligne sud du lot 11C-165, et d'une partie du lot 11C, vingt et un pieds et cinq dixièmes de pied (21.5') dans une autre ligne sud du lot 11C-163, cent quarante-trois pieds et six dixièmes de pied (143.6') et cent quinze pieds et deux dixièmes de pied dans ses lignes ouest le long de la partie du lot 11C; cent dix-sept pieds (117') dans sa ligne est le long des lignes ouest des lots 11C-163 et 11C-164, et cent quarante pieds et quatre dixièmes de pied (140.4') aussi dans une ligne est, le long de la ligne ouest du lot 11C-162, cent trente pieds (130') en arrière dans sa ligne sud, le long de la rue Larocque et a une superficie de vingt-trois mille soixante-dix pieds carrés (23,070 p.c.) ; Avec tous les bâtiments dessus érigés.» et les meubles ci-après décrits constituant le fonds de commerce : Bar-salon 1 piano Story's Clark 7 chaises 1 table ronde en bois 8 tabourets 1 caisse enregistreuse (National 918-51-150) 121 verres 126 verres 9 tasses 1 moulin à glace Ice-O-Matic 56 cendriers 46 cendriers 1 horloge électrique Molson Salle à dîner 7 tables en bois 30 x 36 1 table ronde 1 buffet 1 caisseenregistreu.se (National 4647613-6054-161) Bureau 1 bureau 2 chaises Bar-salon 75 tables en bois 24 x 24 325 chaises en bois et métal 4 tables en bois 8 pi.x 32 po.1 diable 3 tables en bois 24 x 24 62 chaises en bois et métal Cuisine 1 table bois et métal 5 pi.x 34 po.2 chaises bois et métal 62 assiettes 9 po.30 assiettes 5J-£ po.6 assiettes 11^ po.11C-165, 11C-163 and by a part of lot 11C; on the south by Larocque Street; on the west by other parts of lot 11C and on the east by lots 11C-162, 11C-163 and 11C-164; Said emplacement measuring forty-two and one tenth feet (42.1') in front, along Principale Street; seventy-two feet (72') on a north line along the southerly line of lot 11C-165 and a part of lot 11C; twenty-one and five tenths feet (21.5') on another southerly line of lot 11C-163, one hundred forty-three and six tenths feet (143.6') and one hundred fifteen and two tenths feet on its westerly lines along part of lot 11C; one hundred seventeen feet (117') on its east line along the westerly lines of lots 11C-163 and 11C-164, and one hundred forty and four tenths feet (140.4') also on its east line along the westerly line of lot 11C-162, one hundred thirty feet (130') in rear on its south line along Larocque Street and covers an area of twenty-three thousand seventy square feet (23,070 sq.ft); With all the buildings erected thereon.\" and the furniture hereinafter described forming part of the business: Cocktail Lounge 1 Story's Clark piano 7 chairs 1 wooden round table 8 stools 1 cash-register (National 918-51-150) 121 glasses 126 glasses 9 cups 1 Ice-O-Matic machine 56 ashtrays 46 ashtrays 1 \"Molson\" electric clock Dining Room 7 wooden tables 30 x 36 1 round table 1 cabinet 1 cash-register (National 4647613-6054-161) Office 1 desk 2 chairs Cocktail Lounge 75 wooden tables 24 x 24 325 wood and metal chairs 4 wooden tables 8 ft.x 32 in.1 two-wheeled trolley 3 wooden tables 24 x 24 62 wood and metal chairs Kitchen 1 wood and metal table 5 ft x 34 in.2 wood and metal chairs 62 plates 9 in.30 plates 5]/2 in.6 plates 11H in. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 juin 1974, 106' année, n° S3 4373 15 assiettes 6j
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.