Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 juillet 1974, Partie 1 samedi 6 (no 27)
[" JU GAZETTE QUEBEC °\"r OFFICIELLE OFFICIAL sl DU QUÉBEC GAZETTE All ho G3/ will PARTIE 1 PART 1 EX 2 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTCES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4871 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS r\" 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Editeur officiel I S du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient desavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Editeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éd iteur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.S.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Editeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Quebec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai Publieher 4872 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion : 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 11: du 1er janvier au 31 décembre, 820; du 1er avril au 31 décembre, 815 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 fines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: SI each.Slips: S3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December.$10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings.Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n\" 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° S7 4873 AVIS JURIDIQUES\tJURIDICAL NOTICES\t\t\t\t\t Compagnies \u2014 Loi des\tCompanies\t\t\tAct\t\t Abandon de charte\tSurrender of Charter\t\t\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of:\t\t\t\t\t Nom / Name\tIncorporation Date\t\t\tDissolution Date\t\t 3590-65\t\t08\t65\t28\tOil\t74 L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE BELEOIL INC.715467\t.15\t10\t71\t28\t06\t74 B.& W.CONSTRUCTION LTD.1834-64\t.28\t04\t64\t28\t06\t74 4992-66\t\t12\t66\t28\t06\t74 10805-57\t\t03\t57\t1)5\t1)7\t74 J.EDOUARD BOUCHER, LTEE.5512-65\t.17\t12\t65\t28\t06\t74 LA BOUTIQUE ANDRE JAREST, LTEE.3499-69\t.13\t08\t69\t28\t06\t74 LA COMPAGNIE DE L'HOTEL WINDSOR DE HULL.THE HULL WINDSOR HOTEL COMPANY 556-24\t.26\t03\t2-1\t05\t07\t74 CONFECTION CHRISTIANE INC.4993-68\t.24\t10\t68\t28\t06\t74 INDEVCO QUEBEC LIMITED.2478-68\t.29\t05\t68\t28\t06\t74 MADO DEVELOPMENT LTD.14744-60\t.21\t11\t60\t28\t06\t74 723732\t\t06\t72\t21\t06\t74 13484-61\t\t07\t61\t1)5\t07\t74 THE SPORT CLUB OF QUEBEC, INC.2394-29\t\t01\t30\t05\t07\t74 6282-50\t\t09\t50\t05\t07\t74 WESTERN HOME RENOVATIONS INC.RENOVATIONS RESIDENTIELLES WESTERN INC.724220\t.27\t07\t72\t28\t06\t74 57757-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57757-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 4874 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Lettres patentes (1™ partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ACCELERATION PERSONNEL \u2014 SERVICES RESSOURCES HUMAINES INC.ACCELERATION PERSONNEL SERVICES \u2014 HUMAN RESOURCES INC.1356-4687 AEROCOUSTIC INC.1356-4935 AIRLINE SEVENTEEN FIFTY-ONE MACHINIST WELFARE ASSOCIATION INC.L'ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DES MACHINISTES AERIENS DIX-SEPT CINQUANTE ET UN INC.1356-1808 ALTINOR INC.1356-3457 AMBULANCE DEUX MILLE INC.1356-5890 ASSURANCES MARTEL INC.1368-3024 L'ATELIER DE TRANSFORMATION DE BOIS & CRETAGE DE HONFLEUR INC.1356-2095 ATELIER ELECTRONIQUE DES RIVIERES INC.1354-6841 LES ATELIERS D'EBENISTERIE D'ALMA INC.1356-5411 AUTOMOBILE M.ROY INC.1356-4018 AVIATION LIMA INC.LIMA AVIATION INC.1356-5460 BERKSHIRE HOLDING INC.LES PLACEMENTS BERKSHIRE INC.1368-1796 BIJOUTERIE BAIE COMEAU INC.1356-6054 BIJOUTERIE CAMILLE & ANDRE INC.1355-7236 F.& J.BLANCHETTE LTEE.1355-4605 BOIS DELTA LTEE.DELTA LUMBER LTD.1356-2228 MICHEL BOISVERT INC.1368-3792 BOUTIQUE COTILLON INC.1355-4464 100, d'Youville, Québec.10 05 74 24, rue St-Jean, Neufchâtel.13 05 74 3860.Côte Vertu, Saint-Laurent.02 05 74 701, rue Sherwood, Notre-Dame-des- 03 05 74 Laurentides.Lévis.16 05 74 2770, rue Pitre, Brossard.16 05 74 Sainte-Monique.01 05 74 Farnham.23 05 74 Aima.14 05 74 24, rue Salaberry.Salaberry-de-Val- 09 05 74 leyfield.Québec.14 05 74 Montreal.09 05 74 Baie Comeau.15 05 74 85.Ste-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue 30 05 74 Saint-Nicéphore.01 04 74 Montréal.03 05 74 Saint-Hubert.23 05 74 Les Galeries Place Bonaventure, 01 04 74 Concourse Level, Montréal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, fi juillet 1974.106' année, n° 27 4875 Nom / Name I ncorporation Siège social / Head Office Date Rond Point, boulevard Laurier, 26 04 74 Saint«-Foy.4911 Sherbrooke Street West, 29 04 74 suite 1, Montreal.Saint-Paul-L'Ermite.01 05 74 Matagami.08 05 74 Montreal.30 04 74 144, rue Principale, Saints-Anges.19 03 74 5977, 5th Avenue, Montreal.03 05 74 904, des Pins, Saint-Nicolas.03 05 74 10 St-James Street West, Montreal.03 06 74 172, rue des Frênes, Pointe-aux- 08 04 74 Trembles.4824, chemin Côte des Neiges, 24 05 74 Montréal.Montréal.19 04 74 935 Liège Street West, Montreal.01 04 74 Montreal.12 06 74 2490, Croissant Moreau, Brossard.06 05 74 Saint-Laurent.14 05 74 Montreal.06 05 74 5605 Pinedale, Côte Saint-Luc.17 04 74 Sept-Iles.06 03 74 2090, avenue Trois-Rivières, Duvernay.07 05 74 Québec.16 05 74 BOUTIQUE DE BERNIERES INC.1356-1139 C.B.DESIGN LTD.DESIGN C.B.LTEE 1367-9949 C.I.ASPHALT & LANDSCAPE CO.INC.LA COMPAGNIE D'ASPHALTE & DE TERRASSEMENT C.I.INC.1368-0509 CARRIER & BOULAY INC.1368-1564 CENTRE LAVAL (1974) INC.1368-0251 LES CHEVRONS R.B.R.INC.1355-0066 LA COMPAGNIE D'EXPEDITION SEARAM LTEE.SEARAM DISPATCHERS CO.LTD.1368-0855 CONSTRUCTION DEPLOUR INC.1356-3515 LES CONSTRUCTIONS A.C.M.INC.A.C.M.CONSTRUCTION INC.1368-5219 LES CONSTRUCTIONS MARIO & FRERES INC.1355-6956 LA COTE, HAUTE COIFFURE INC.1356-8035 COUVREURS F.M.INC.F.M.ROOFING INC.1367-8537 CREMAZ1E AUTO REPAIR (1974) INC.REPARATION AUTOMOBILE CREMAZIE (1974) INC.1355-4597 CUM CONSTRUCTION LTD.CONSTRUCTION CUM LTEE 1357-1567 DANISABEL INC.1356-3036 DANSBEC INC.1368-2703 DAVI CORPORATION LTD.CORPORATION DAVI LTEE 1356-3218 DAVIS & LEMISH INC.1367-8206 MARTIN J.DEVOE & FILS INC.MAfiTIN J.DEVOE & SON INC.1354-4234 DISTRIBUTION DOMESTIQUE ARLEF INC.1356-3655 DISTRIBUTION VANIER LTEE.VANIER DISTRIBUTION LTD.1356-5940 4876 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1971,, Vol.106, No.27 Nom / Name EMESAR LTD.EM ES A K LTEE 1367-9683 ENTREPRISES A.R.D.RODRIGUE INC.A.R.D.RODRIGUE ENTERPRISES INC.1355-4969 LES ENTREPRISES BOILY & FILS INC.1356-4653 LES ENTREPRISES DALCOURT ET ROUSSEL INC.DALCOURT AND ROUSSEL ENTERPRISES INC.1368-0442 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES BEDFORD INC.1356-7110 ENTREPRISES FELDER INC.1356-8506 LES ENTREPRISES G.M.B.D.LTEE.1356-3143 LES ENTREPRISES J.G.F.LTEE.1356-5262 LES ENTREPRISES J.M.THIBAULT INC.J.M.THIBAULT ENTERPRISES INC.1367-5301 LES ENTREPRISES J.P.B.R.INC.1368-4220 ENTREPRISES JOROC INC.1367-9873 LES ENTREPRISES NOEL BRIAND INC.1356-3903 LES ENTREPRISES OCTAVE INC.1356-2418 LES ENTREPRISES PABEVA INC.1356-5270 ENTREPRISES PYLO INC.1356-8522 ERECTION BRETON LTEE.1368-3560 EUROPEX INVESTMENTS LTD.LES INVESTISSEMENTS EUROPEX LTEE 1368-1077 LE8 EXCAVATIONS M.G.NAUD INC.M.G.NAUD EXCAVATION INC.1368-0459 LA FERME LES LOISIRS PLEIN-AIR INC.1357-0544 LA FERME TRACEL INC.1355-4852 LES FERMES DE CAILLES DU QUEBEC INC.QUEBEC QUAIL FARMS INC.1356-6955 LES FIBRES PERALU INC.1368-0913 Incorporation Siège social / Head Office Date Montreal.26 04 74 15435, Boischatel, Pierrefonds.03 04 74 Haut*rive.10 06 74 8183, rue Langelier, Montréal.01 05 74 Sainte-Sabine.21 05 74 Québec.27 05 74 Arvida.06 05 74 117 Lemieux, Repentigny.14 05 74 26, rue Fortin, Saint-Basile-le-Grand.14 05 74 661, boulevard du Séminaire, Saint- 27 05 74 Jean.3312, Place Victoria, Montréal.29 04 74 Sept-Iles.07 05 74 945, rue Fulton, Sherbrooke.02 05 74 925.boulevard Maloney, Templeton.14 05 74 Québec.27 05 74 Montréal.22 05 74 Montreal.06 05 74 6026, rue Houde, Montréal-Nord.01 05 74 1525, de la Vérendry, Québec.10 06 74 Sorel.02 04 74 Montréal.24 05 74 223, St-Hubert, Granby.03 05 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n\" 27 4877 Nom / Name LES FRUITS DE MER LAGABEAU INC.1356-1386 GARAGE MARIO LAROSE LTEE.1354-9381 A.GERMAIN ET ASSOCIES INC.1368-0103 GESTION A.L.G.INC.1355-3573 GESTION NASPOR INC.1367-6663 GESTIN INC.1356-7078 LES HABITATIONS A.C.M.INC.i4.C.A/.HOMES INC.1368-5201 HABITATIONS RAYNI INC.1356-7094 HOTEL MOTEL LE MAS INC.1356-4810 BERNARD HOULE & FILS INC.1356-4158 LES IMMEUBLES DALQUIER INC.1356-6948 IMMEUBLES DONORA LTEE.DONORA REALTIES LTD.1367-5111 IMMEUBLES HENRI PAUL BELANGER INC.HENRI PAUL BELANGER REALTIES INC.1354-6791 IMMEUBLES LOCKPORT LTEE.LOCKPORT REALTIES LTD.1367-5160 LES IMMEUBLES PRINTANIERS INC.1356-7680 INDUSTRIES BEN RIOUX LTEE.1355-2641 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES R.B.INC.1356-1352 JACBOUROY INC.1356-1576 JOVAN ENTERPRISES LTD.ENTREPRISES JOVAN LTEE.1367-1508 KITCHENER HOLDINGS QUEBEC LIMITED.LES PLACEMENTS KITCHENER QUEBEC LIMITEE.1356-3721 B.LAMARRE & ASSOCIES LTEE.1367-9576 LAUNEL INC.1356-4349 GILLES LEBEAU INC.1354-6437 Incorporation Siège social / Head Office Date 101, rue Lasalle, Jonquière.30 04 74 Fugèreville.14 03 74 12, rue Vézina, Sainte-Thérèse.30 04 74 Saint-Félicien.19 04 74 4S50, Côte-des-Neiges, No 1903, 05 04 74 Montréal.50, Place Crémazie, Montréal.21 05 74 10 St.James Street West, Montreal.03 06 74 148, rue Bellerive, Saint-Rédempteur.21 05 74 1441 Matane-sur-Mer, Matane.10 05 74 12, rue Dupré, Sorel.09 05 74 Amos.22 05 74 1 Place Ville Marie, Suite 3635, 28 03 74 Montréal.39.rue Turgeon, Sainte-Thérèse.11 03 74 1 Place Ville Marie.Suite 3635, 28 03 74 Montréal.28, rue Court, Granby.27 05 74 Amqui.26 03 74 1702, 5e Avenue, Charny.30 04 74 223, rue Principale, Vallée-Jonction.29 04 74 5744 Durocher, Outremont.11 03 74 Dorval.07 05 74 Montréal.26 04 74 876, rue Francis, Longueuil.10 05 74 220, rue S-Jacques, Saint-Jean.11 03 74 4878 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.ion.No.27 _ Nom / Name LE MANOIR COTE ST-PAUL INC.1367-7158 MING AN INDUSTRIES INC.LES INDUSTRIES MINGAN INC.1356-4455 MOTEL LE BASTION (1974) INC.1355-7657 NORMONT DEVELOPMENT CORPORATION LTD.CORPORATION D'AMENAGEMENT NORMONT LTEE 1356-6799 NORTON DISTRIBUTORS INC.LES DISTRIBUTEURS NORTON INC.1356-4729 PATISSERIE DES MONTS INC.1368-0145 PAVAGE CHABOT INC.1356-8860 PEPINIERE ANDRE MASSON INC.1355-7467 PHOTO S.R.T.INC.S.R.T.PHOTO INC.1368-0400 PIECES D'AUTOMOBILE IDEAL, TERREBONNE INC.IDEAL AUTO PARTS.TERREBONNE INC.1356-0487 PIERMAXI INC.1356-3796 PINARD & PINARD (1974) LTEE 1368-1861 LES PLACEMENTS A.A.S.LTEE A.A.S.INVESTMENTS LTD.1356-4315 PLACEMENTS DALVIN INC.1356-4083 PLACEMENTS REVIK INC.1356-8530 PLANIGESCO INC.1354-2246 PLAQUES D'IMPRIMERIE C.M.L.INC.C.M.L.PRINTING PLATES INC.1367-9089 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION GERRY LTEE GERRY'S PLUMBING.HEATING.VENTILATION LTD.1356-2160 PLURIGEST INC.1356-5510 POPULAR PRODUCE & POULTRY INC.PRODUITS AGRICOLES & AVICOLES POPULAIRES INC.1355-2690 LA PORCHERIE MAUMIFER INC.1357-1591 PUBLICITE LANAUDIERE INC.1355-7319 Incorporation Siège social / Head Office Date 1402 de l'Eglise Street, Côte St.Paul, 08 04 74 Montréal.289, des Menuisiers, Sept-Iles.10 05 74 2923, boulevard Hamel, Les Saules.10 04 74 Montreal.21 05 74 1040, avenue Provost, Lachine.10 05 74 90.rue de l'Eglise.Saint-Sauveur-des- 30 04 74 Monts.Tourville.27 05 74 Rimouski.09 04 74 2214, chemin Chambly, Longueuil- 01 05 74 4930, Chemin Gascon, Saint-Louis-de- 25 04 74 Terrebonne.Montréal.07 05 74 620, rue Lindsay, Drummondville.10 05 74 180, Deguire Boulevard, Saint-Laurent 08 05 74 Québec.09 05 74 Québec.27 05 74 210, boulevard Charestest, Québec.27 03 74 Montréal.24 04 74 Hull.01 05 74 500, Grande Allée est, suite 609, 15 05 74 Québec.7549 Querbes Avenue.Montreal.26 03 74 Courcelles.27 05 74 Joliette.09 04 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' aimée, n° 27 4879 Nom / Name REMORQUES BOUCHERVILLE LTEE.BOUCHERVILLE TRAILERS LTD.1368-0657 RESTAURANT LA REDOUTE, 1974) INC.1357-0296 ROTISSERIE PETIT PERE INC.1354-6635 SALON CONRAD INC.1354-5025 LES SCIERIES B & W INC.1356-3317 SERVICE DE RADIO VICTOR INC.VICTOR RADIO SERVICE INC.1357-2094 SERVICE DE RESSORTS CHOMEDEY (1974) INC.CHOMEDEY SPRINGS SERVICE (1974) INC 1368-4451 SERVICE DU CAMION BEAUCEVILLE INC.BEAUCEVILLE TRUCK SERVICE INC.1356-3820 SERVICES DE CHAUFFEURS BISON INC.BISON DRIVER SERVICES INC.1367-7448 LEN SHUGAR ET ASSOCIES LTEE.LEN SHUGAR AND ASSOCIATES LTD.1367-8164 SIGNALEX INC.1368-3925 SOGEX INC.1356-9439 SON VA DEVELOPMENT CORPORATION LTD.CORPORATION D'AMENAGEMENT SONVA LTEE 1356-6781 SOUTH SHORE FACTORY OUTLET INC.MAGASIN DE VETEMENT EN GROS DE LA RIVE SUD INC.1368-2075 SPECIALITES EN COMBUSTION S.D.INC.S.D.COMBUSTION SPECIALISTS INC.1367-9006 STEED AUTOMOTIVE INDUSTRIES (EASTERN) LIMITED LES INDUSTRIES AUTOMOBILES STEED (EST) LIMITEE 1357-0346 STUCAGE CAMDEN INC.1356-1592 LES TAPIS M.& M.INC.1356-8910 LEONCE THIBODEAU & FILS LTEE.1356-7623 TRANSPORT N.G.B.INC.N.G.B.TRANSPORT INC.1355-4654 Incorporation Siège social / Head Office Date Boucherville.02 05 74 Québec.13 03 74 Thetford-Mfnes.11 03 74 2848, boulevard Rosemont, Montréal 07 03 74 7042, boulevard Pie IX, Montréal____ 06 05 74 31, 1ère Avenue ouest, Sainte-Anne- 13 06 74 des-Monts.15, rue Dubé, Laval.28 05 74 Route Kennedy, Beauceville-Est.07 05 74 Montréal.09 04 74 1221 Crescent Street, Montreal.17 05 74 1975, rue O'Brien, Laval.24 05 74 3145, Des Métayers, Giffard.28 02 74 Montreal.21 05 74 311 Churchill boulevard, Montreal .29 05 74 1052, Seigneur Lussier, Saint-Vincent- 23 04 74 de-Paul, Laval.2322 Lucerne Road, Mount Royal 07 12 73 Shopping Centre, Mount Royal.3850, chemin Bibeau, Fleurimont____ 29 04 74 Brossard.04 06 74 Maria.21 05 74 415, Père Lacombe, Québec.01 04 74 4880 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6.1974, Vol.106, No.27 Nom / Name\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date UNIFORMES ET ROBES ERIKA INC.1356-050c\tSainte-Foy.\t.24 03 74 VARNA LTEE.1355-3151\t.9400, rue Papineau, Montréal .\t____ 27 03 74 VERDUN CRICKET CLUB, MONTREAL INC.CLUB DE CRICKET VERDUN, MONTREAL INC.1355-0058\t\t____ 19 03 74 WINCO ENTERPRISES INC.\t\t LES ENTREPRISES WINCO INC.1356-2368\t\t YELLOW BIRD RENTALS OF QUEBEC LTD.LOCATION L'OISEAU JAUNE DU QUEBEC LTEE 1356-6252\t.6035, Côte de Liesse North, Saint-Laurent.\t15 05 74 Le directeur du service des compagnies, 57757-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 57757-0 Director of the Companies Service.\t Administrateurs\tDirectors\t Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs tel qu'indiqué ci-après.\tNotice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed the number of their directors as indicated hereinafter.\t Nom de la compagnie Name of Company Date de constitution Dale of incorporation Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Previous number Nouveau nombre New number BELMONT REALTIES LIMITED 13175-51 BIJOUTERIE LUCIEN LAROSE INC.736456 CJRP RADIO PROVINCIALE LIMITEE.13368-57 COMETAL INC.521-63 FALLINGER CORPORATION .1794-71 GERARI INC.733711 HOTEL PAUL BAILLARGEON (JONQUIERE) INC.740092 HOTEL ROYAL LAC-MEGANTIC INC.281-71 LES IMMEUBLES C.J.L.R.INC.13784-59 JURIHOME INC.12444-61 LABORATOIRE DU-VAR INCORPOREE.DU-VAR LABORATORY INCORPORATED 2311-47 18 10 51 26 02 73 25 10 57 04 02 63 07 04 71 23 08 73 09 01 74 20 01 71 29 06 59 12 05 61 25 02 47 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 37 4881 Nom de la Compagnie Name of Company\tDate de constitution Dale of incorporation\t\tNombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous number New number\t GABRIEL LUSSIER LTEE.GABRIEL LUSSIER LTD.12075-55\t01\t08 55\t4\t3 MARCHE L.D.J.A.INC.736883\t19\t04 73\t4\t3 MINAKAKIS TRAVEL SERVICE INC.2005-71\t20\t04 71\t3\t4 MODELLA INC.5391-66\t2?\t12 66\t4\t3 MODERN TECHNICAL SERVICES (.QUEBEC DIVISION) LTD.SERVICES TECHNIQUES MODERNES (DIVISION DE QUEBEC) LTEE 4283-70\t30\t09 70\t5\t3 J.MONTEMURRO INC.1455-63\t18\t04 63\t5\t6 PIERCE INVESTMENT CORP.12327-62\t29\t05 62\t3\t4 POST-PRODUCTIONS INC.956-68\t05\t03 68\t3\t4 POTTERTON PRODUCTIONS INC.888-68\t09\t04 68\t4\t7 PRENOR GROUP LTD.GROUPE PRENOR LTEE 14909-61\t12\t10 .61\tS\t9 LE REGIONAL LTEE.4643-66\t17\t02 67\t11\t7 LES RESTAURANTS B & R INCORPOREE.2652-71\t19\t05 71\t4\t3 RESTAURANTS RENAISSANCE INC.5054-70\t17\t11 70\t4\t3 SOCIETE DE MECANIQUE DE CONSTRUCTION SOMEC INC.330-69\t22\t01 69\t4\t3 THE SOMERVILLE HOUSE CORPORATION.721235\t17\t01 72\t6\t3 SUPERSEAL CORPORATION.49065-53\t25\t11 53\t5\t7 THERAPEX CORPORATION .1835-68\t22\t04 68\tS\t7 10858-56\t16\t03 56\t8\t9 9263-49\t16\t12 49\t4\t5 TREBMALTS LIMITED.\t16\t12 49\t5\t4 9263-49 57757-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57757-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. -ISS2 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 lettres patentes (3' partie) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation: Nom / Name Siège social (Article 81) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci-après.Letters Patent (Part III) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Incorporation Siège social / Head Office Date Presbytère St-Simon, rue St-Edgard, 05 12 73 Drummondville-Sud.2500 Rosemont Boulevard, Montréal.16 04 74 Saint-Hyacinthe.02 05 74 2975, chemin St-Louis, Sainte-Foy.15 03 74 690.rue Collard, Alma.08 05 74 Charlemagne.13 05 74 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Head office (Section 84) Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed their head office as indicated hereinafter.CERCLE D'AMITIE DE L'AGE D'OR DE DRUMMONDVILLE-SUD.1368-4816 CERCLE DE BRIDGE ROSEMONT LTEE.1367-7992 CLUB DE RALLYE AUTO YAMASKA (C.R.A.Y.).1368-0780 CLUB SOCIAL DES EMPLOYES DU CENTRE CARDINAL VILLENEUVE INC.1354-9076 CORPORATION CULTURELLE.ARTISTIQUE ET SOCIALE D'ALMA.1356-4232 CORPS MUSICAL LES DUCHESSES DE CHARLEMAGNE 1356-4950 Le directeur du service des compagnies, 57757-0 Pierre Desjardins.57757-0 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Prtvious address New address ACTION VEHICLE CORPORATION.08 04 70 8357.Jean-Nicolet, 1021-70 Saint-Léonard.AGENCE G.B.INC.15 08 73 Laval.733611 ALBERT PREVENTIVE MAINTENANCE INC.30 04 68 5797, rue Dubreuil, 1915-68 Saint-Léonard.ASSOCIATION DU LAC VERT INC.19 10 65 55, Strathearn, Montréal- GREEN LAKE ASSOCIATION INC.Ouest.4581-65 AU JARDINET INC.30 07 64 57.rue St-Jacques ouest.2845-64 Montréal.C.BARBER CARTAGE LIMITED.15 01 44 Saint-Lambert.1113-44 BOULANGERIES UNIES INC.22 08 56 Dolbeau.12451-56 3845, Ste-Catherine est, Montréal.294, boulevard Ste-Rose, Sainte-Rose.10,754.avenue Salk, Montréal.4330, 3ième Avenue, Laval-Ouest.1695, boulevard des Laurentides, Laval.425, boulevard Guimond, Longueuil.1242, boulevard St-Jean-Baptiste, Rivière-du-Moulin. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 juillet 1974, 106' amUe, n° 27 4883 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address BOVET INC.10366-59 BRASSERIE DES REMPARTS INC.RAMPARTS BREWERY INC.730905 24 01 59 2567, Ontario est, Montréal.4477 Métropolitain est, Saint-Léonard.CANADA PACKAGING LTD.11506-59 LE CHATEAUNEUF BOISE INC.2972-69 CHEMINEES HARVEY INC.5372-68 CHOLAR INC.740537 01 03 73 Québec.800, Place Victoria, suite 2810, Montréal.04 08 59 Saint-Henri-de-Mascouche.493, rue Léveillé, Terre-bonne.13 06 69 Cowiinsville.1050, avenue du Parc, Laval.12 11 68 Montréal.365, rue Broadway, Montréal-Est.11 02 74 Québec.COMMERCIAL LITHO PLATE GRAINING (1970) LTD.2899-70 LA COMPAGNIE GRANITE ETERNITE LIMITEE.THE ETERNITE GRANITE COMPANY LIMITED.13455-61 .3770, rue Le Corbusier, Sainte-Foy.06 07 70 Montreal.4355, boulevard Sir Wilfrid Laurier, Saint-Hubert.02 08 61 202, rue Wilson, Sherbroo- 520, Champoux, Dis- COMPUMATCH INC.842-70 CONCRETE INVESTMENT INC.2778-66 CONFECTION IDEALE INC.4319-65 ke.24 02 70 1155 Dorchester Boulevard West, Montreal.04 07 CONSTRUCTION CONTROLE INC 717019 CORANIT INC.5700-70 D.D.TRANSPORT LTEE.3700-64 DECOR-METAL LTD.1224-64 DEMENAGEMENTS ST-LAURENT INC.2097-67 DERNIERE HEURE LTEE.5927-68 DISTRIBUTEURS DELORIMIER (1971) INC.2854-71 LES DISTRIBUTIONS DU NORD-OUEST DU QUEBEC INC.725080 LES ENTREPRISES CAPRICORNE LIMITEE.5069-69 822, Jean-Bois, Boucherville.29 09 65 Saint-Samuel-de-Gayhurst.20 12 71 Rivière-du-Loup,.31 03 71 1435, rue St-Alexandre, Montréal.18 08 64 10635, rue Racette, Montréal-Nord.02 03 64 715, rue St-Maurice, Montréal.09 05 67 Trois-Rivières.12 12 68 Mont-Royal.31 05 71 Pointe-Claire.12 09 72 Macamic.LES ENTREPRISES PARE INC.3208-69 04 11 69 Montréal.08 07 69 Montréal.raëli.20 Surrey Gardens, Westmount.1400, avenue des Pins, Montreal.Route Rurale numéro 1, Sainte-Cécile.2075, rue des Cèdres, Saint-Bruno-de-Montar-ville.773, avenue Clairmont, Sainte-Foy.8513, Place Verdelle, Anjou.2100, chemin Remembrance, Lachine.425, boulevard Guimond, Longueuil.5701, Christophe-Colomb, Montréal.360, boulevard Lebeau, Saint-Laurent.409 est, rue Perreault, Rouyn.2140, rue Labelle, app.8, Longueuil.11833, rue Hurteau, Montréal-Nord. 4884 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie- Xante of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'AIR 01 04 66 Montréal.10780, rue Pascal Gagnon, INC.Montréal-Nord.AIR DISTRIBUTION EQUIPMENT INC.1003-66 ETREFAL INC.12 07 51 1405.rue Peel, Montréal.170.boulevard Industriel, 9775-51 Parc Industriel Boucherville.CONRAD FORGET INC.18 04 56 Saint-Jovite.10850, rue St-Hubert, 11191-56 Montréal.GEREM INC.04 03 71 442, boulevard St-Cyrille 3119.rue Chambord.4546-70 ouest, Québec.Sainte-Foy.GESBEC INC.22 12 72 533.31e Avenue.LaSalle .2579.rue Dollard.726722 Longueuil.GESTION LA SAVANE INC.10 10 62 5200, rue de la Savane, 1250, rue Nobel, 14070-62 Montréal.Boucherville.THE GRAND LODGE OF QUEBEC OF THE 13 10 66 5679 Eadie Street, 1448 Moreau Street, ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES Montreal.Lasalle.INC.4137-66 HOTEL DON NACONA LTEE.23 04 65 Donnacona.104, rue Jacques-Cartier 1712-65 est, Chicoutimi.HOTEL ST-LAZARE INC.04 09 68 Saint-Lazare 2695.rue St-Joseph.3995-68 Saint-Hyacinthe.LES INDUSTRIES DALLAIRE LTEE.16 08 71 Saint-David 790.Jean-Marie Morin.DALLA I RE INDUSTRIES LTD.Lauzon.714231 TOM JACOBSEN INC.12 03 71 3335.Ridgewood Avenue.240 SomervaleGardens, 1249-71 Apt.16, Montreal.Apt.9, Pointe-Claire.JEAN-MARC LAJOIE LTEE.31 01 68 Alma.22, rue Hébert, 421-68 Hébertville.FRANCOIS LAMY & ASSOCIES, INC.27 08 65 146, Montée des Trente, 205, Montée Pré-Vert, 3600-65 Saint-Hilaire.Beloeil.LAPORTE CONSTRUCTION INC.04 07 66 822.Jean-Bois.1400.avenue des Pins.2776-66 Boucherville.Montréal.D.LARUE LIMITEE 28 11 44 Québec .180.rue Blouin, Vanier.6080-44 LERCH ENTERPRISES LTD.16 04 68 Montreal.310 Victoria Avenue, LES ENTREPRISES LERCH LTEE Suite 409, Westmount.r&¥Y2N CONSTRUCTION INC.26 10 66 6535.boulevard Gouin est.584, boulevard des Prai- 4351-66 Montréal-Nord.ries.Laval.LUCERNE ELECTRIQUE LTEE.04 10 67 Plaza Glenwood, Lucerne.84, rue Montclair, Hull.LUCERNE ELECTRIC LTD.4190-67 MICHEL.MARQUIS INC.26 03 69 Saint-Jérôme 4170, 4e Avenue est, 8\"-69 Charlesbourg.^D.MATTE INC.23 01 70 333 Main Street, Magog.77 Anjou Boulevard, .(0.J-70 Châteauguay centre.LUDOVIC MONTPETIT INC.14 01 56 Salaberry-de-Valleyfield .52.rue Grenier.10122-56 Melocheville. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4885 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie - Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address LES MOULINS A SCIE SARRAZIN INC.07 11 66 181, Montée du Moulin, 856, boulevard Labelle, SARRA7.IN SAW-MILLS INC.Laval.Blainville.4395-66 MOULURES PROGRESSIVES INC.12 05 70 3737 Métropolitain Bou- 5425 Industrial Boulevard, PROGRESSIVE MOULDS INC.levard East, Montreal.Montreal North.2063-70 NASH EQUIPMENT CORP.16 04 56 Montréal.5125.Côte Vertu, 11158-56 Saint-Laurent.OPERA HOLDING LIMITED.08 01 68 Montréal.312, rue Meloche, GESTION OPERA LIMITEE Saint-Laurent.72-68 LES OPERATIONS FORESTIERES BARRETTE 21 12 65 Lebel-sur-Quévillon .Comtois, Abitibi-Est.& SAUCIER LTEE 5558-65 PAPETIERS DEAUVILLE INC.22 09 65 Montreal.5579 Pinedale Avenue, DEAUVILLE STATIONERS INC.Côte-Saint-Luc.4238-65 THE PENGUIN SKI CLUB.03 08 38 Piedmont.728 Upper Landsdowne 1509-38 Avenue, Montreal.PETIT JOURNAL LTEE.12 12 68 Mont-Royal.5701, rue Christophe- 5926-68 Colomb, Montréal.PHOTO JOURNAL LTEE.12 12 68 Mont-Royal.5701, rue Christophe- 5925-68 Colomb, Montréal.LES PLACEMENTS TEMA INC.17 09 71 Saint-Gérard.234.rue Dufferin, 714969 suite 200, Sherbrooke.PLAMONDON AUTOMOBILES INCORPORE.20 07 56 Saint-Raymond.Cap-Santé.12351-56 PLANI-VERT INC.18 05 71 36, rue St-Louis, Lévis 558, Trans-Canada Ouest, 2623-71 Saint-David-de-l'Aube- rivière.PROGRESS WIRE WORKS INC.20 10 67 8015, rue Dante, 6793, Place Pascal, 4342-67 Montréal.Gagnon, Montréal-Nord.R.RAYMOND 4 ASSOCIES LTEE.25 10 65 2835, chemin Gomin.880, chemin Ste-Foy, 4704-65 Sainte-Foy.Québec.LES RESTAURANTS LES GRANDS 25 08 72 Montréal-Nord.6020, rue Joseph-Renaud, VAISSEAUX INC.Anjou.724753 ROBEC CONSTRUCTION INC.19 12 67 Trois-Rivières.5360, boulevard 5288-67 Jean XXIII, Trois- Rivières-Ouest.ST-LOUIS TRANSPORT INC.26 06 64 Saint-Louis-de-Gonzague .Saint-Etienne.2842-64 SERENA INC.30 09 69 Hull.9405.rue Berri, Montréal.4703-69 LE SERVICE DE DISTRIBUTION RICHELIEU 25 08 72 Montréal-Nord.6020, rue Joseph-Renaud, INC.Anjou.724756 SIROIS INC.30 11 64 Montréal.701, rue St-Marc, 4617-64 Joliette.SO GE HAB INCORPOREE .13 02 70 Québec.908, Chapman, 707-70 Ancienne-Lorette. -ism; QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July G, 1974, Vol.106, No.87 Incorporation Siège social Nom de la compagnie Name of the company\t\tDate\t\tAncienne adresse Previous address\tNouvelle adresse New address LA SOCIETE APICOLE DU VAL FLEURI INC.724604\t17\t08\t72\t4 est, rue Notre-Dame, Montréal.\t95.rue de l'Eglise, Napierville.2032-65\t30\t04\t65\t1255 Phillips Square, Room 605, Montreal.\t4, rue de l'Equerre.Sainte-Rose, Laval.NAT TEPPER INC.1363-69\t25\t03\t69\t1044 Elizabeth Boulevard, Laval.\t471 Algonquin Avenue, Mount-Royal.TIFFANY CANADIAN LTEE.CANADIAN TIFFANY LTD.726437\t04\t12\t72\t8681.8e Avenue, Montréal.\t6600, rue Magloire, Saint-Léonard.VINCENT & CO.INC.\t27\t01\t36\t\t2000, rue Francis Hugues.108-36\t\t\t\t\tLaval.57757-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57757-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Domicile legal (Article 30) Legal domicile (Section 30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé tel qu'indiqué ci-après.Notice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have established their principal office or have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ABERDEEN CLOTHING CO.28 10081-57 ALPHONSE ALLARD INC.08 1582-64 ALLIANCE TRANS-KEBEC ALLIANCE LTEE .26 12307-57 ASCENSEURS VIAU INC.15 VIAU ELEVATORS INC.738313 L'ASSOCIATION DU MOUVEMENT SCOUT 28 BON-PASTEUR (LAVAL) INC.2987-66 BON AVENTURE ENTERPRISES LIMITED .01 LES ENTREPRISES BONAVENTURES LIMITEE 12411-57 CHAMPI.ON THREAD (197S) LTD.23 LE FIL CHAMPION (1973) LTEE 1354-2683 ELIE CHARBONNEAU & FILS INC.30 2353-63 ROGER CHARBONNEAU LTEE.27 12129-57 05 57 Montréal.160, rue St-Viateur, suite 509, Montréal.04 64 Québec.176, rue St-Pierre, Québec.07 57 Montréal.8527, boulevard St- Laurent, Montréal.10 73 5253, boulevard Décarie, Montréal.07 66 336.rue Cartier, Laval-des-Rapides, Laval.8255.Mountain-Sights, Montréal.400, rue Laurier.Laval-des-Rapides, Laval.08 57 Montréal.1390, rue William, Montréal.11 73 Montreal.Ill Chabanel Street West, Suite 101, Montreal.05 63 Montréal.2193, rue Sauriol est.Montréal.06 57 331, rue Notre-Dame, Cap-de-la-Madeleine.292, boulevard Ste-Made-leine, Cap-de-la-Madeleine. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G juillet 1974, 106' année, n° S7 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address LA CIE DE POLISSAGE ET PLACAGE ACME LTEE ACME BUFFING & PLATING CO.LTD.5326-68 CIE DE TABAC TERREBONNE LIMITEE .6245-46 CLUB OPTIMISTE DE ROUYN-NORANDA INC.715947 CLUB VICTOIRE.C.C.P.27-45 PETER COHEN REALTIES INC.3725-66 COLAMAC INC.954-68 COMM.ELECTRIC CO.INC.12215-54 LES CONSTRUCTIONS ALBERT SANS- CARTIER INC.746008 DAWCO REALTIES LTD.3952-68 DEJALEX LTEE 716838 DEVELOPPEMENT CONSEIL INC.1523-69 LES DEVELOPPEMENTS C.T.D.INC.C.T.D.DEVELOPMENTS INC.3248-64 DIRECTO PUBLICATIONS INC.431669 JEAN-PAUL DUMAIS INC.15697-61 DUROTALON CORPORATION 14062-60 EMERY'S EXCLUSIVE FURS INC.13019-54 L'ENTRAIDE MISSIONNAIRE.10612-58 ENTREPRISES DU SAGUENAY INC.11573-55 FEDERATION PROVINCIALE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSIMILEES 3523-71 FLAM TEXTILES CO.LTD.13475-55 FORTCREgT INC.12861-54 14 11 68 2730, Desautels, Saint-Hubert.12 09 46 405, rue St-Louis, Terrebonne.3450, boulevard Losch, Saint-Hubert.477, rue St-Louis, Terrebonne.15 11 71 Rouyn.161, rue Principale, Rouyn.21 06 45 Jonquière.477, rue de la Tamise, Jonquière.12 09 66 4770 Kent Avenue, 33 Côte Ste-Catherine Suite 202, Montreal.Road, Montreal.12 03 68 Montréal.5464, Iberville, Montréal.03 09 54 827 Beaumont Street, Montreal.03 01 74 Montréal.03 10 13 12 02 04 16 07 30 09 07 12 19 09 13 12 05 03 09 06 18 06 68 4770 Kent Avenue, suite 202, Montreal.71 107, rue St-Jacques, Montréal.69 Sherbrooke.64 466, rue de la Couronne, suite 218, Québec.69 Montréal.61 Rimouski.60 4698, avenue Westmount, Westmount.54 Montreal.58 Montréal.55 Chicoutimi.71 4265, Papineau, Montréal.M.FREDER TEXTILES INC.10695-62 22 12 55 372 Ste.Catherine Street West, Montreal.23 12 54 340 Dominion Square Building, Montreal.07 02 62 Montreal.8305 Durocher Street, Montreal.8037, rue DeLorimier, Montréal.33 Côte St.Catherine, Montreal, 1010 Côte Beaver Hall, suite 750, Montréal, 1441, rue St-Esprit.Sherbrooke.1675, Carré Ader, app.2, Québec.300, rue St-Sacrement, Montréal.401, boulevard de la Rivière, Rimouski.4800, rue Maisonneuve, ouest, app.623, Westmount.5327 Sherbrooke Street West, Montreal.1216, rue Panet, Montréal.641, Chemin Sydenham, Chicoutimi.9335, rue St-Hubert, Montréal.99 Chabanel Street West, Montreal.1440 Towers Street, suite 100, Montreal.5437 Casgrain Avenue, Montreal. 4sss QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.July 6.1974.Vol.10G.No.27 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie -\" Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address GIROUX, PHANEUF ET ASSOCIES INC.01 10 65 235 Dorchester Boulevard 465 St-Jean, Apt.508, 3752-65 East, Apt.202, Montreal.Montreal.GREEN PARK INVESTMENT CORP.31 03 70 Montréal.1255, rue Université, 1 ids.t(i suite 1610, Montréal.THE HASEN CORPORATION.13 12 71 Montreal.7471 Leonardo da Vinci 717362 Street, Montreal.HOTEL PAUL BAILLARGEON (JONQUIERE) 09 01 74 Jonquière.214, rue St-Dominique, INC.Jonquière.7-|()l l'.u LES IMMEUBLES BERTFORT INC.21 04 64 Montréal.:.3895.rue Bélanger, 1755-64 Montréal.INTERSTYLE GROUP LTD.05 11 62 Montreal.9500 Meilleur Street.14485-62 Montreal.l.AFARGE CONCRETE LTD.23 08 46 620 ouest, boulevard 606.rue Cathcart, LAFARGE BETON LTEE Dorchester, Montréal.Montréal.6168-46 EUGENE LA VOIE INC.20 04 54 Québec.580, rue Grande-Allée est, 11045-54 Québec.LILKLAR HOLDINGS LTD.10 02 64 Montreal.9500 Meilleur Street, 659-64 suite 103, Montreal.LOUSEL INC.02 04 63 Montréal.8220, rue Le Creusot, 1476-63 Montréal.A.MARCHESSAULT LIMITEE.23 09 63 Montréal.2530, rue Logan.Montréal.3774-63 MONTBEC COMPANY LIMITED.21 09 64 3300 Cavendish Boulevard.8205 Montreal-Toronto 4147-64 Montreal.Boulevard, Montreal.NORTHERN PACKERS LTD.04 11 54 Montréal.1201, rue Mill, Montréal.12668-54 MICHEL PAQUET INC.17 11 66 Hauterive.101, rue Bel-Air, 4604-66 Hauterive.LE PAYSAN DE CHAMBLY INC.10 11 66 Chambly.1310.rue Bourgogne, 4237-66 Chambly.DONAT ST-YVES INC.12 12 61 62.rue St-André, 564, boulevard des Sei- 16051-61 Terrebonne.gneurs, Terrebonne.SAMUELS PLUMBING & HEATING INC.11 03 68 3025 Victoria Avenue.221 - 8th Avenue, Lachine.815-68 Lachine.SCENE HOLDINGS INC.27 09 66 Montreal.225 Chabanel Street West.3910-66 Montreal.SEMCO INVESTMENT CORP.30 06 65 901 Bleury Street.1255 University Street, 3019-65 suite 450, Montreal.suite 1620, Montreal'.SERVICE REGIONAL DES LOISIRS DE 25 03 47 Montréal.445 rue St-Francois- 2689M7°NTREAL X'aVi6r' Montr6al- SIDMOR CHILDREN'S WEAR LTD.23 03 54 Montréal.120 rue Laurier ouest 10619-54 Montréal.S0C^S ?^F,amNr-IQUE DE C0N8TRUC- 22 01 69 Sa»\"»-^.759.rue Barolet.Sainte- TION SOMEC INC.330-69 Foy.pTn\\H«QUEEN DRESS INC\u2014 04 07 56 Montréal.225.rue Chabanel ouest.12089-56 Montréal. GAZETTE OFG ICI ELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4889 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address SUMMIT CORPORATION.10574-57\t27\t03\t57\tMontréal.\t5555, rue Casgrain, Montréal.EDMOND SYLVAIN LIMITEE 1954.10687-54\t., 26\t03\t54\t336.rue Dorchester, Québec.\t70, rue Dorchester sud.Québec.TAVERNE YVAN LTEE.14516-62\t09\t11\t62\t950, rue Jarry ouest, Montréal.\t3488, rue Dandurand, Montréal.TELECABLE DE LA RIVE-SUD INC.714055\t02\t08\t71\t91, rue St-Georges, app.210, Lévis.\t108, Côte du Passage, Lévis.717194\t\t12\t71\t2095, rue Calvados, Saint-Bruno-de-Montarville.\t1530, boulevard Marie-Victorin, Saint-Bruno-de-Montarville.57757-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57757-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettrée patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act.he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation Date L.P.S./ S.L.P.Date Modifications Changes ASSOCIATION DES AUXILIAIRES 11 06 71 FAMILIALES DIPLOMEES DE LA PROVINCE DE QUEBEC CERTIFIED HO M EM A KER ASSOCIATION OF QUEBEC 3119-71 AUTOMOBILES DU ROI INC.16 05 74 DU ROI AUTOMOBILES INC.1356-5536 BRITTON ELECTRIC CO.LTD.09 09 54 LA CIE ELECTRIQUE BRITTON LTEE 12141-54 ROBERT CLEMENT INC.13 03 72 721409 FONDATION RICHELIEU QUEBEC.20 07 72 724088 WILFRID GREGOIRE-LUMBER-LAND INC 06 03 62 10310-62 KWIKASAIR LTD.29 11 71 716551 LES PRODUITS COMTOIS LTEE.10 10 72 725620 11 04 74 1) Ancien nom / Former name: ASSOCIATION DES AUXILIAIRES FAMILIALES DIPLOMEES DE QUEBEC / CERTIFIED HOME-MAKER ASSOCIATION OF QUEBEC 2) Changeant le nombre des administrateurs / Changing the number of directors.3) Etendant les pouvoirs / Extending the powers.03 06 74 Modifiant le capital / Altering the capital.25 07 73 Modifiant le capital / Altering the capital.18 12 73 Etendant les pouvoirs / Extending the powers.28 03 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.01 05 74 Ancien nom / Former name: WILFRID GREGOIRE INC.06 06 74 Modifiant le capital / Altering the capital.18 06 74 Ancien nom / Former name: CAQUETTE & SAUCIER INC. 4890 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.37 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changée QUINCAILLERIE BAIE-COMEAU INC 735763 27 12 73 SOCIETE NATIONALE DES QUEBECOIS DE 06 06 62 LA COTE-NORD (SSJB) INC.12491-62 16 05 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.30 04 74 Ancien nom / Former name: LA SOCIETE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA COTE NORD Le directeur du service des compagnies, 57757-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 57757-0 Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivant:\tThe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date ALRUGA INC.402-68 BBROL LTD.BEROL LTEE 6605-48 CITY LAUNDRY AND UNIFORM RENTAL LTD.BUANDERIE ET LOCATION D'UNIFORMES CITE LTEE 8393-56 COMMERCE DU PLASTIQUE & DU CAOUTCHOUC INC.PLASTIC & RUBBER TRADING CO.INC.12422-60 MARCEL R.DE COTRET INC.746011 DISCOTHEQUE FUMEE LIQUIDE INC.LIQUID SMOKE DISCOTHEQUE INC.738275 GARAGE T.O.S.LTEE.734470 LES HUILES PENCO-OLYMPIC INC.3529-70 IMPRIMERIE BARONET LTEE BARONET PRINTING LTD.5524-63 PHILIP B.FASHIONS INC.MODES PHILIP B.INC.729089 LES PUBLICATIONS DU MESSAGER INC.2503-69 AVANTI FORMAL WEAR INC.HABITS DE GALA AVANTI INC.EAGLE NORTH-RITE LTD.CITY LAUNDRY AND DRY CLEANING \"VERDUN\" LTD.30 01 68 19 10 48 08 01 47 PLASTIC & RUBBER TRADING CO.06 06 60 INNATCO INC.03 01 74 BAR SALON MIRAGE INC.26 09 73 CENTRE DE SPORTS DE PLEIN AIR T.O.S., 10 10 73 TERRASSE VAUDREUIL INC.T.O.S.OUTDOOR CENTER.TERRASSE VAUDREUIL INC.LES HUILES OLYMPIC INC.13 08 70 OLYMPIC OIL INC.BARONET ACCESSOIRES DE BUREAU ET 19 12 63 IMPRIMERIE LTEE BARONET OFFICE SUPPLIES AND PRINTING LTD.BUTTERFLY SEVEN SPORTSWEAR INC.03 10 72 VETEMENTS DE SPORT PAPILLON SEPT INC.PUBLICATIONS DUMONT INC.23 06 69 57767-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57757-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4891 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu > (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b)'transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 4892 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MTV QPY Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCY QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA .lit Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Fink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Maure Brun Brown M 000001 Q 000001 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M 500001 Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 à Q 001000 à M 103000 à Q 102000 à M 210000 à Q 205000 à M 303000 à Q 302000 à M 402000 àQ 401000 à M 504000 àQ 503000 à M 601000 àQ 600500 à M 700500 à Q 700500 à M 800500 à Q 800500 à M 900500 à Q 900500 \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport- \u2014 passengers ^,pF \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers .' Québec public transport \u2014 students m£r _ ^Io.n,réa' transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab ^CR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking WCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage .' Québec regular transportation \u2014 trucking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4893 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCY \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation ¦\u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Quebec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail I - Avis de la Commission « proprio .notu > : La Commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.I \u2014¦ Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to settle the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Rôle Q-1362 Q-503919 P-l Q-800 M.LÉO MURDOCK 180.Mgr de Laval Chicoutimi, Québec Rôle Q-1371 1290-DY 1070-DYV P-l CD.LOCATION ENRG.(Cléo Danis opérant sous le nom de/operating under the name of) CP.323 Cap-aux-Meules (Iles-de-la-Madeleinei, Québec Rôle Q-1384 11437-V P-l TF L'ISLET EXPRESS INC., St-Eugène, Cté LTslet, P.Q.Rôle M-2383 M-942 & M-941 23480-V P-l & 7737-V P-l MONSIEUR JULIEN MOREAU 8945 Vézeau, app.3 Montréal, P.Q.Requérante / Applicant BELLECHASSE TRANSPORT INC.3600 boul.Wilfrid Hamel Les Saules, Québec 8, Que.Requérante-conjointe Joint applicant Aux fins de réviser la décision rendue par la Commission le 7 mai 1974 pour, s'il y a lieu, la modifier, la révoquer ou la confirmer.Aux fins de réviser la decision QL-113 datée du 18 février 1974, en y corrigeant le nom exact de la requérante comme il apparaît sur la formule No 2 de la requête CTQO-25 du 26 novembre 1973, CD.Location Enrg.(Cléo Danis opérant sous le nom de).Aux fins de décréter la remise du dépôt en cautionnement de $50.00 fait par la requérante dans la décision No QS-322-TF du 1er mai 1974.Aux fins de: Reviser la décision MCS-459 rendue par la Commission des transports du Québec le 1er avril 1974: Pour corriger le paragraphe No 4 de la page 2 de ladite décision, lequel paragraphe décrète la remise de la somme de $50.00 (reçu No 021466) à Kenneth Roy Peters alors qu 'en réalité le cautionnement aurait dû être remis au requérant Julien Moreau, ledit paragraphe devant se lire comme suit: 4.Décrète la remise delà somme de $50.00 (reçu No 021466) déposée par Julien Moreau, ainsi que la somme de $50.00 (reçu No 021-465) déposée par Bellechasse Transport Inc., conformément aux dispositions du règlement No 2.For the purpose of revising the decision rendered by the Commission on May 7, 1974, in order to modify, quash, or confirm it, if need he.For the purpose of revising decision QL-113 dated February 18, 1974, by correcting therein the exact name of the applicant as it appears on form No.2 of application CTQO-25 of November 26, 1973, CD.Location Enrg.(Cléo Danis, operating under the name of).For the purpose of ordering the reimbursement of the deposit of $50.00 made by the applicant in decision No.QS-322-TF, dated May 1, 1974.For the purpose of: Revising decision MCS-459 rendered by the Québec Transport Commission on April 1, 1974: Correcting paragraph No.4.on page 2 of said decision, which paragraph orders the reimbursement of the sum of $50.00 (receipt No.021466) to Kenneth Roy Peters, whereas the deposit should actually have been reimbursed to the applicant.Julien Moreau, said paragraph should read as follows: 4.orders the reimbursement of the sum of $50.00 (receipt No.021466) deposited by Julien Moreau, and of the sum of $50.00 (receipt No.021465) deposited by Bellechasse Transport Inc.in conformity with the provisions of Regulation No.2. 4894 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Rôle M-2403 1210-DY & 945-DYV P-l LOCATION D'AUTOS DE MONTRÉAL LTÊE MONTREAL AUTO LEASING LTD 4795, Ste-Catherine ouest Montréal, P.Q.Rôle M-2477 919-DYV-P-l METRO TANK LEASING (MONTREAL) INC.4545, boul.Lavoie St-Vincent-de-Paul Ville de Laval, P.Q.Rôle M-2486 1273-DY & 1055-DYV-P-l MOUSSETTE CHRYSLER PLYMOUTH LTÊE 1400, boul.Curé-Labelle Chomedey Laval P.Q.Rôle M-2487 650-V-P-l ST-BRUNO TRANSPORT INC.369, rue Robastalière B.P.550 St-Bruno.Cté Chambly, P.Q.Rôle M-2489 3546-A-P-l PAQUETTE, MADAME RÉJANE 26, rue Poitras, St-Gabriel, (Berthier) P.Que.Rôle M-2488 23328-V-P-l MONSIEUR LÉONARD RAVENELLE Ste-Pie.Cté Bagot.P.Q.Rôle M-2490 1392-V-P-l FOURNIER TRANSPORT LTÉE 109, de l'Eglise Lacolle, P.Q.Rôle Q-1388 7863-V-P-l QS-365 TRANSPORT MORNEAU INC.St-Arsène Cté Rivière-du-Loup, P.Q.Rôle Q-1394 97-A-P-l Q-745 AUTOBUS DRUMMONDVILLE LTÉE 330, rue Hériot Drummondville Québec Aux fins de réviser la décision ML-35 du 13 juillet 1973, et autoriser la remise du montant de $76.00 ce qui n'était pas mentionné dans la décision concernée.For the purpose of revising decision ML-35 of July 13.1973, and authorizing reimbursement of the sum of $75.00, which was not mentioned in the decision concerned.Aux fins de disposer de l'erreur d'écriture dans la décision rendue le 5 février 1974 ; 1.le numéro du dossier devrait être 918-DYV 2.et devrait être Volume 1-4-51.Aux fins de disposer de l'erreur de rédaction du nom qui aurait dû être; Moussette Chrysler Plymouth Inc.For the purpose of rectifying the error in the wording of the decision rendered on February 5.1974; 1.the file number should be 918-DYV 2.and should be Volume 1-4-51.For the purpose of rectifying the error in the wording of the name, which should have read: Moussette Chrysler Plymouth Inc.Aux fins de corriger la décision .MCS-443 du 24 avril 1974, cause M-4495 en amendant le dispositif No 4 pour indiquer que le dépôt confisqué est $25.00, le montant réel déposé avec l'opposition de « Nil Girard Transport Ltée », et radiant du dispositif No 5 le nom de cette dernière, pour laquelle un remboursement est décrété.Aux fins de révoquer la décision rendue le 25 février 1974 - No M PV-209 - dossier No 3546-A (D.l.) cause M.685, vu l'absence de règlement.For the purpose of correcting decision MCS-443 of April 24, 1974, case M-4495, by modifying enacting term No.4.in order to indicate that the amount of the confiscated deposit is $25.00 the actual amount deposited by \"Nil Girard Transport Ltée\" with its objection, and deleting from enacting term No.5 the name of the latter, wherefor a reimbursement is ordered.For the purpose of cancelling the decision rendered on February 25, 1974 - No.MPV-209-file No.3546-A (D.l.) case M.685, owing to failure to settle the matter.Aux fins de réviser sa décision MCR-827 du 2 avril 1974, cause M-4507 dans laquelle fut décrétée la confiscation du dépôt de $25.00 indiqué sur la RT-54 du 4 juin 1973, alors que le dépôt réel était au montant de $50.00 lequel fut déposé avec la requête, en vertu de l'arrêté en couseil 1275 du 25 mars 1970.(Vérifié au Service de la comptabilité).RE: Decision MS-530 en date du 11 mars 1974.Aux fins d'annuler la condition suivante apparaissant au permis spécial No 1392-V S-l: « Ce permis spécial devra être opéré conjointement avec un permis de l'Inter-state Commerce Commission ».Aux fins de réviser la décision rendue par la Commission le 7 juin 1974 pour corriger l'erreur dans les références au numéro du dossier et au numéro de la cause.For the purpose of revising its decision MCR-827 of April 2.1974.case M-4507, which ordered the confiscation of the deposit of $25.00 indicated in RT-54 of June 4, 1973, whereas the actual deposit amounted to $50.00 which was deposited with the request, pursuant to Order in Council 1275 of March 25, 1970.(Verified by the Accounting Service).RE: Decision MS-530 dated March 11, 1974.For the purpose of cancelling the following condition appearing on special permit No.1392-V S-l: \"This special permit shall be operated in conjunction with a permit issued by the Interstate Commerce Commission\".For the purpose of amending the decision rendered by the Commission on June 7, 1974, in order to correct the error in the references to file number and case number.Aux fins de réviser la décision QPV-291, remplaçant l'annexe « A » accompagnant la décision par l'annexe « A » qui accompagnait la demande.For the purpose of amending decision QPV-291, replacing schedule \"A\" attached to the decision by schedule \"A\" attached to the application. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4895 Rôle Q-1398 1650-A-P-l LES AUTOBUS LACHANCE INC.CP.91.St-Martin, Cté Beauce, P.Que.(Dist.-jud.No 23 Québec) Rôle Q-1400 25-N-P-l LA COMPAGNIE DE NAVIGATION DE TROIS-PISTOLES LTEE Trois-Pistoles Cté Rivière-du-Loup, P.Q.Aux fins de corriger le deuxième considérant de la décision QPV-302, page 2, lequel se lit comme suit: Considérant les dispositions de l'article 16.6 du règlement No 16 .Par le suivant : Considérant les dispositions del'Ordonnan-ce générale No 17 concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie.Aux fins de disposer du cautionnement fait par la partie opposante et qui n'apparaît pas dans la décision rendue le 5 mai 1972.For the purpose of correcting the second preamble to decision QPV-302, page: 2, which reads as follows : Considering the provisions of section 16.6 of Regulation No.16.By the following: Considering the provisions of General Order No.17 concerning special or chartered trips.For the purpose of disposing of the deposit made by the opposing party, and which is not mentioned in the decision rendered on May 5, 1972.Rôle Q-1401 1238-DY-P-l CAMPWAGON (Johan Roy, Lucien Barbeau.Raymond Moisan opérant sous le nom de / operating under the name of:) 683, route Lagueux Bernières, Cté Lévis, P.Q.Aux fins de disposer du cautionnement fait par la requérante et qui n'apparatt pas dans la décision du 30 juillet 1973.For the purpose of disposing of the deposit made by the applicant, which is not mentioned in the decision rendered on July 30, 1973.Rôle Q-1402 259-N-P-l MARCEL DUFOUR St-Bernard-sur-Mer Ile-aux-Coudres Cté Charlevoix, P.Q.Aux fins de disposer des cautionnements faits par le requérant et la partie opposante et qui n'apparaissent pas dans la décision rendue le 30 juillet 1973.For the purpose of disposing of the deposits made by the applicant and the opposing party, which are not mentioned in the decision rendered on July 30, 1973.Rôle Q-1403 1153-DY-P-l ELPHÈGE BÉLANGER 11349, rue Pigeon Montréal Nord, P.Q.Aux fins de disposer de la demande de révocation du permis par lettre du détenteur du dossier.For the purpose of disposing of the request for cancellation of permit filed by the holder.Rôle Q-1404 772-DY-P-l CLAUDE GUERTIN LOCATION 5, rue St-Paul St-Félicien Cté Roberval, P.Q.Aux fins de disposer de la demande de révocation du permis faite par le détenteur.For the purpose of disposing of the application for cancellation of permit made by the holder.Rôle Q-1420 21508-V-P-l LAURÉAT CANUEL 179, rue Courtemanche Matane, P.Q.Aux fins de révoquer les clauses a et 6 du permis numéro 21508-V.For the purpose of cancelling clauses a and 6 of permit number 21508-V.57759-0 I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu \u2022 : La Commission donne avis qu'elle entend décider de Parfaire suivante, conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les quinze jours francs de la date de la présente publication.1 \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to render a decision in the following matter, in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of fifteen clear days following the date of this publication.For the purpose of verifying the permit held by the aforesaid.Rôle Q-1410 Aux fins de vérifier le permis du précité.20493-V-P-l GRENIER, RÉNALD St-Méthode-de-Frontenac Cté de Frontenac 4896 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Rôle Q-1372 16903-V-P-2 CARTIER TRANSPORT INC.153 rue Maltais Sept-Iles Cté Saguenay, Que.Rôle Q-1373 760-V-P-l NIL.GIRARD TRANSPORT LTÉE 1777 boul.Talbot Chicoutimi Cté Chicoutimi, Que.G7H 5B1 Rôle M-2408 13889-V P-l JEAN-PAUL TRUDEAU & FILS LTÊE 70, Rang des 24 Beloeil, Cté Verchères, P.Q.Aux fins de réviser la décision du 17 mai 1974 (QCS-310, 16903-V-D-l.rôle Q-412), pour disposer du cautionnement de la partie-requérante.Aux fins de réviser la décision du 10 mai 1974 (QCR-593, 760-V-D-l, cause Q-134), quant au montant du cautionnement remis à la partie-requérante.Pour corriger la décision relativement au remboursement du dépôt de l'opposante, St-Bruno Transport Inc.No 650-V, qui n'a pas été décrété, lors de la décision de La Commission datée du 29 octobre 1973.For the purpose of revising the decision dated May 17, 1974.(QCS-310, 16903-V-D-l, Roll Q-412), in order to dispose of the applicant's deposit.For the purpose of revising the decision dated May 10, 1974, (QCR-593, 760-V-D-l.case Q-134), with regard to the amount of the deposit reimbursed to the applicant.For the purpose of correcting the decision relating to the reimbursement of the deposit made by the opposing party, St-Bruno Transport Inc.No.650-V, which reimbursement was not ordered in the decision of the Commission dated October 29, 1973.57759-0 II \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.New application.Haulaway transport - contract-Request is made to authorize Marcel Côté to haul, with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Gérard Nolin Ltée, (15957-V), according to clauses a to i inclusive, ft to p inclusive and r of said permit No.15957-V.Rôle Q-1363 23872-V-D-l CÔTÉ, MARCEL 35, rue Lafranee Notre-Dame-des-Laurentides Cté Québec, Que.Tireur / drawer 15957-V GÉRARD NOLIN LTÉE 150, rue de l'Eglise St-Jean-Chrysostome Cté Lévis, Que.Tiré / drawer Nouvelle demande.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Marcel Côté à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Gérard Nolin Ltée, (15957-V), selon les clauses a à i incl., ft à p incl.et r, dudit permis No 15957-V.Rôle Q-1364 7147-V-D-5 L.THIBODEAU TRANSPORT INC.228.2ième Avenue Portneuf Cté Portneuf, Que.Modification de permis.La requérante désire que soit ajouté aux clauses h et j de son permis le terminus de Bécancour de façon à ce que lesdites clauses se lisent à l'avenir comme suit: h) Transport général - longue distance -route restreinte - h) De Bécancour, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Yamachiche et St-Barthélemy à Montréal et retour pour le transport de marchandises destinées aux six (6) premiers endroits ou en provenant sauf le transport de produits ou marchandises destinés à la fabrique de produits laitiers Lauren-tide Ltée (Crino) ou en provenant.j) Transport général - longue distance -route restreinte - j) De Bécancour et Trois-Rivières à Québec et retour.Restriction : La détentrice n'est pas autorisée à faire la cueillette ou la livraison dans le rayon de cinq (5) milles de Bécancour.Modification of permit.\" The applicant requests that the terminal of Bécancour be added to clauses h and j of its permit so that said clauses read henceforth in the future : (A) General trucking - long distance - restricted route - (h) From Bécancour, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Yamachiche and St.Barthélémy to Montreal and return for the transport of goods shipped to or originating from the first six (6) points excluding products or goods shipped to or originating from the dairy Laurentide Ltée (Crino).O) General trucking - long distance - restricted route - (j) From Bécancour and Trois-Rivières to Québec and return.Restriction : The permit-holder is not authorized to provide a pick-up and delivery service within a radius of five (5) miles from Bécancour. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n' 27 4897 La requérante désire également être autorisée à donner le service de transport suivant: Transport général - longue distance - route restreinte - De Bécancour à Trois-Rivières et retour.Rôle Q-1365 7737-V-D-4 BELLECHASSE TRANSPORT INC.3600, boul.Hamel Québec Cté Québec, Que.Modification de permis.La partie requérante qui est autorisée en vertu des clauses m et n à donner le service de transport suivant: m) Transport général - longue distance -route - m) De Nicolet et de Ste-Angèle à Montréal, et retour.Droits additionnels: 1, Ce service comprend aussi les points intermédiaires entre Ste-Angèle et Yamaska (cette localité incluse), ainsi que St-Célestin, St-Léonard et Ste-Monique.2.En donnant les services autorisés par la clause m de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à Trois-Rivières, Trois-Ri-vières-Ouest et Cap-de-la-Madeleine, via le point de Trois-Rivières, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale No 7225 du 22 février 1972.n) Transport général - longue distance -route restreinte - n) De Sorel, Yamaska, St-François-du-Lac, Pierreville, La Baie, Nicolet, St-Gré-goire, Ste-Angèle, St-Célestin, St-Léonard-d'Aston, Ste-Monique à Québec, et retour.Droit additionnel: En donnant les services autorisés par la clause n de son permis, la détentrice est autorisée à faire la cueillette et la livraison des marchandises à Trois-Rivières, Trois-Ri-vières-Ouest et Cap-de-la-Madeieine, via le pont de Trois-Rivières, nonobstant les dispositions de l'Ordonnance générale No 7225 du 22 février 1972.desire que le terminus Ste-Angèle mentionné dans ces deux clauses soit remplacé par Bécancour.Rôle Q-1366 1009-V-D-l THIBODEAU, GEORGES Ste-Christine Cté Portneuf, Que.et/and 7147-V-D-4 L.THIBODEAU TRANSPORT INC.228, 2e Avenue Portneuf Cté Portneuf, Que.Demande de transfert.George Thibodeau demande l'autorisation de transférer la clause 6 de son permis de transport No 1009-V à la compagnie: L.Thibodeau Transport Inc.(7147-V) 228 - 2ième Avenue Portneuf Cté Portneuf, Que.la clause b du permis No 1009-V : Transport général.Occasionnellement de Ste-Christine à Québec et retour, pour le transport de marchandises destinées a Ste-Christine ou en provenant.Rôle Q-1367 23039-V-D-4 SEPT-ÎLES TRANSPORT INC.Souris, I.P.E.Place d'affaires au Québec: Head Office in Québec: 608, rue Cartier Sept-Iles Cté Saguenay Que.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De la frontière Québec-Nouveau-Bruns-wick (tous ports d'entrée) à la frontière Québec-Ontario (tous ports d'entrée), en transit, pour le transport de produits manufacturés et non manufacturés de la mer et de la ferme, originant de Souris, Charlottetown etSummerside (I.P.E.) et Woodstock (N.B.), et requérant l'usage de camions isothermes, pour le compte de Alvin Keenan Ltd.The applicant also requests authorization to provide the following transport service: General trucking - long distance - restricted route \u2014 From Bécancour to Trois-Rivières and return.Modification of permit.The applicant, which is authorized to provide the following transport service, according to clauses m and n : (m) General trucking - long distance -route - (m) From Nicolet and Ste.Angèle to Montreal, and return.Additional rights: 1.This service also includes the intermediate points between Ste.Angèle and Yajnas-ka (including said locality) and between St.Célestin, St.Léonard and Ste.Monique.2.When providing the services authorized by clause m of its permit, the permit-holder shall be authorized to pick up and deliver goods in Trois-Rivières, Trois-Rivières-West and Cap-de-la-Madeleine via the Trois-Rivières Bridge, notwithstanding the provisions of General Order No.7225, dated February 22, 1972.(n) General trucking - long distance - restricted route - (n) From Sorel, Yamaska, St.Francois-du-Lac, Pierreville, La Baie, Nicolet, St.Grégoire.Ste.Angèle, St.Célestin, St.Léo-nard-d'Aston, Ste.Monique to Québec, and return.Additional right : When providing the services authorized by clause n of its permit, the permit-holder shall be authorized to pick up and deliver goods in Trois-Rivières, Trois-Rivières-West, and Cap-de-la-Madeleine via the Trois-Rivières Bridge, notwithstanding the provisions of General Order No.7225, dated February 22, 1972.requests that the Ste.Angèle terminal mentioned in said two clauses be replaced by that of Bécancour.Application for transfer: Georges Thibodeau requests authorization to transfer clause 6 of his transport permit No.1009-V to: L.Thibodeau Transport Inc.(7147-V) 228 - 2nd Avenue Portneuf County of Portneuf, P.Q.clause b of permit No.1009-V: General transport.Occasionally, from Ste.Christine to Québec and return, for the transport of goods destined to or originating from Ste.Christine.Modification of permit: The applicant requests that the following service be added to its permit : Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From the Québec-New Brunswick border (all ports of entry) to the Québec-Ontario border (all ports of entry), in transit, for the transport of processed and non-processed sea and farm products, originating from Souris, Charlottetown and Summerside, (P.E.I.), and Woodstock, (N.B.), and requiring the use of temperature-controlled trucks, on behalf of Alvin Keenan Ltd. 4898 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.47 Rôle Q-1368 23039-V-D-3 SEPT-ÏLES TRANSPORT INC.Souris, I.P.E.Place d'affaires au Québec: Head Office in Québec: 608, rue Cartier, Sept-Iles Cté Saguenay, Que.Rôle Q-1369 18627-V-D-6 TRANSOL INC.124, rue St-Pierre Québec, Cté Québec, Que.Rôle Q-1370 23876-V-D-l PAUL BRETON INC.44 rue St-Thomas Montmagny Cté Montmagny, Que.et / and 11374-V-D-l EXCAVATIONS CÔTÉ INC.CÔTÉ EXCAVATIONS INC.1 rue Forgues St-David-de-1'Auberivière Cté Levis, Que.Rôle Q-1376 22020-V-D-l ST-LAURENT, LEO (décédé / deceased) 206 rue Fournier Matane Cté Matane, Que.et / and ST-LAURENT, DAME MARIE-JEANNE BERNIER 206 rue Fournier Matane Cté Matane, Que.Légataire universelle Universal legatee Rôle Q-1377 7863-V-D-2 TRANSPORT MORNEAU INC.St-Arsène Cté Rivière-du-Loup, Que.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant : Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De la frontière Québec-Nouveau-Bruns-wicfc (tous ports d'entrée), à Québec et Montréal, pour le transport de produits manufacturés et non manufacturés de la mer et de la ferme, originant de Souris, Charlottetown et Summerside (I.P.E.) et Woodstock (N.B.), et requérant l'usage de camions isothermes, pour le compte de Alvin Keenan Ltd.La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec pour obtenir la permission de louer, à court terme (moins d'une année), de Transol Location Inc., permis numéro 887-DYV, les camions et les semi-remorques dont la liste est déposée à la Commission des transports du Québec.Demande de transfert.La compagnie Paul Breton Inc.demande que les clauses d et e de son permis de transport No 11374-V soient transférées à la compagnie: (23876-V) Excavations Côté Inc.Côté Excavations Inc.1 rue Forgues St-David-de-l'Auberivière Cté Lévis.Que.les clauses d et e du permis de transport No 11374-V: Transport restreint - longue distance -rayon - par fardier - De tous les endroits situés dans le district électoral-provincial de Montmagny à ailleurs dans la province, dans un rayon de 250 milles et retour, pour le transport, par fardier, de machinerie lourde, d'outillage et de marchandises volumineuses, sauf Trois-Rivières et Montréal.Transport restreint - longue distance -territoire - par équipement spécialisé- Entre tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Bellechasse.Montmagny et LTslet, pour le déplacement de bâtisses et maisons, par fardier et équipement spécialisé.Transmission par décès.La légataire universelle demande l'autorisation d'exploiter le permis de transport No 22020-V qu'opérait de son vivant, son époux, feu Léo St-Laurent à savoir: Transport restreint - longue distance -territoire - par équipement spécialisé - Entre tous points situés dans les districts électoraux-provinciaux de Matane, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Matapédia et Rimouski, pour le déplacement de maisons, par équipement spécialisé.Condition: Cette autorisation est sujette à l'émission d'un permis par le ministère des transports concernant la longueur, largeur et pesanteur.Modification de permis.La partie requérante, détentrice d'un permis dont la clause / se lit: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De Québec à Ste-Anne-de-la-Pocatière, pour le transport de liqueurs alcooliques, Modification of permit: The applicant requests that the following service be added to its permit: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From the Québec-New Brunswick border (all ports of entry) to Québec and Montreal, for the transport of processed and non-processed sea and farm products, originating from Souris, Charlottetown and Summerside (P.E.I.), and Woodstock, (N.B.), and requiring the use of temperature-controlled trucks, on behalf of Alvin Keenan Ltd.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to lease, on a short-term basis (less than one year), from Transol Location Inc., permit number 887-DYV, the trucks and semitrailers listed in the files of the Québec Transport Commission.Application for transfer.Paul Breton Inc.requests that clauses d and e of its transport permit No.11374-V be transferred to: (23876-y) Excavations Côté Inc.Côté Excavations Inc.1 Forgues Street St-David-de-1 'Auberivière County of Levis, P.Q.clauses d and e of transport permit No.11374-V: Restricted trucking - long distance -radius - by float - From all points located in the Provincial Electoral District of Montmagny to any point in the Province, within a radius of 250 miles and return, for the transport of heavy machinery, large-size equipment and goods, by float, Trois-Rivières and Montreal excepted.Restricted trucking - long distance -territory - by special equipment - Between all points located in the Provincial Electoral Districts of Bellechasse, Montmagny and LTslet, for the moving of buildings and houses, by float and special equipment.Transfer for cause of death.The universal legatee requests authorization to operate the transport permit No.22020-V, which was operated by her husband in hislifetime, the late Léo St-Laurent, namely: Restricted trucking - long distance -territory - by specialized equipment - Between all points located in the Provincial Electoral Districts of Matane, Gaspé-North, Gaspé-South, Matapédia and Rimouski, for the moving of houses, by specialized equipment.Condition: The aforesaid authorization is subject to the delivery of a permit by the Department of Transport with respect to the length, width and weight.Modification of permit.The applicant, holder of a permit whose clause / reads: Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - From Québec City to Ste-Anne-de-la-Pocatière, for the transport of alcoholic GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 197L 106' année, n° 27 4899 Rôle Q-1378 22208-V-D-l TESSIER, RAYMOND 82 rue St-Louis Warwick Cté Arthabaska, Que.Rôle Q-1379 1997-V-D-3 A.CLAVEAU TRANSPORT INC.123 boul.Taschereau Kénogami Cté Chicoutimi, Que.Rôle Q-1380 16832-V-D-2 BÉLANGER, HERVÉ St-Damase-de-LTslet Cté.LTslet, Que.Tireur / Haulaway operator GÉRARD NOLIN LTÊE 150, De l'Eglise St-Jean-Chrysostome Cté Lévis, Que.Requérants-conjoints Joint applicants Tiré / Carrier pour le compte de la Société des Alcools du Québec.Demande que la susdite clause soit modifiée en y ajoutant, après les mots « Ste-Anne-de-la-Pocatière », les mots « et St-Pascal ».Demande de permis.La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint-service local-contrat-Warwick et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité, pour le transport de marchandises, pour le compte de la Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada.Modification de permis.La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec pour ajouter les mots « et retour » à la clause suivante de son permis: Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Kénogami à tous les endroits situés dans un rayon de 75 milles des limites de ladite cité, pour le transport de marchandises pour le compte de la Compagnie Price Limitée.Service additionnel.Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Hervé Bélanger à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Gérard Nolin Ltée, (15957-V), selon les clauses aki inclusivement, k à p inclusivement et r dudit permis No 15957-V.beverages, on behalf of The Québec Liquor Corporation.Requests that the aforesaid clause be modified by adding the words \" and St-Pascal\" after the words \"Ste-Anne-de-la-Pocatière\".Application for permit: The applicant requests the following permit: Restricted trucking-local service-contract-Warwick and all points located within a distance of 5 miles from the limits of said Towns, for the transport of goods, on behalf of the Canadian National Railways Company.Modification of permit: The applicant requests the Québec Transport Commission to add the words \"and return\" to the following clause of its permit.Restricted trucking - long distance -radius - contract - From.Kénogami to all points located within a radius of 75 miles from the limits of said city, for the transport of goods on behalf of Compagnie Price Limitée.Additional service.Haulaway transport - contract -Request is made to authorize Hervé Bélanger to haul with his duly-registered tractors, the trailers belonging to Gérard Nolin Ltée, (15957-V), according to clauses a to t inclusive, k to p inclusive and r of said permit No.15957-V.Rôle Q-1381 10694-V-D-2 J.-P.BLANCHETTE TRANSPORT LTÉE 303 ouest, Mgr.Tessier CP.35 Rouyn Cté Témiscamingue, Que.Rôle Q-1382 15179-V-D-l SACRÉ-COEUR TRANSPORT ENR.(Claude Tremblay) CP.291 Sacré-Coeur-de-Jésu8 Cté Saguenay, Que.Modification de permis.La partie requérante, détentrice d'un permis dont la clause A se lit: Transport général - longue distance -route restreinte - De Matagami à Rivière Rupert (Mille 160) et à tous les endroits intermédiaires, et retour.Droit additionnel: Â l'occasion du service précité, la détentrice est aussi autorisée à desservir tous les endroits situés sur la route d'hiver Rupert-L.G.-2 (Mille 386) et Rupert-Fort Georges (Mille 430).Restrictions: 1.En donnant le service précité, la détentrice n'est pas autorisée à se servir de fardier.2.Ce permis est émis sur une base temporaire et expérimentale et se terminera le 31 octobre 1974 à moins qu'il n'ait été prolongé ou rendu permanent à la demande de la détentrice ou par décision de la Commission.Demande que la susdite clause devienne permanente.Modification de permis.La partie requérante demande d'ajouter à son permis les services suivants : Transport restreint - service local - contrat - Sacré-Coeur-de-Jésus et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites dudit endroit, pour le transport, par véhicules spécialement agen- Modification of permit.The applicant, holder of a permit whose clause h reads: General trucking - long distance - restricted route \u2014 From Matagami to Rivière Rupert (Mile 160) and to all intermediate points, and return.Additional right: When providing the above-mentioned service, the holder shall be authorized to serve all points located on the winter road extending from Rupert-L.G.-2 (Mile 385) to Rupert-Fort Georges (Mile 430).Restrictions: 1.When providing the above-mentioned service, the holder is not authorized to use floats.2.This permit is issued on a temporary and experimental basis and shall expire on October 31, 1974, unless it has been extended or made permanent at the request of the holder or by decision of the Commission.Requests that the aforesaid clause become permanent.Modification of permit.The applicant requests that the following services be added to its permit: Restricted trucking - local service - contract - Sacré-Coeur-de-Jésus and all pointslocated within a distance of 5 miles from the limits of said point, for the transport of prefabricated houses, by specially equipped vehicles. 4900 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6.1974, Vol.106, No.27 ces, de maisons préfabriquées, pour le compte de Pré-Nord Inc.Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - De Sacré-Coeur-de-Jésus à tout point situé dans un rayon de 500 milles des limites dudit endroit, et retour avec marchandise endommagée, pour le transport, par véhicules spécialement agencés, de maisons préfabriquées, le tout pour le compte de Pré-Nord Inc.on behalf of Pré-Nord Inc.Restricted trucking - long distance - radius - contract - From Sacré-Coeur-de-Jésus to any point located within a radius of 500 miles from the limits of said point, and return with damaged goods, for the transport of prefabricated houses, by specially-equipped vehicles, of the whole on behalf of Pré-Nord Inc.Rôle Q-1383 Q-503879 RIVERIN, LOUIS-MARIE 2030 Boul.St-Paul Chicoutimi Cté Chicoutimi, P.Q.Requérant cédant Applicant-transferer et / and Q-503970 CIMON, LAVAL 639, rue Lapointe Chicoutimi Cté Chicoutimi, P.Q.Requérant cessionnaire Applicant-transferee Demande de transfert.Riverin, Louis-Marie demande à la Commission de transférer à: Cimon, Laval 639, rue Lappinte Chicoutimi Cté Chicoutimi, P.Q.le permis ou l'attestation Q-503879 qu'il dé- ¦ tient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 2, catégorie entrepreneur.Application for transfer.Riverin, Louis-Marie requests the Commission to transfer to: Cimon, Laval 639 Lapointe Street Chicoutimi .County of Chicoutimi.P.Q.his permit or certificate No.Q-503879 to effect bulk trucking service in Region No.2.contractor class.Rôle Q-1385 1336-DY & 1146-DYV-D-l GARAGE ROBERT GAGNON & FILS LTEE C P 369 Cap Chat, Cté de Matane P.Q.Nouvelle demande.La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques jusqu'à 5 tonnes pour le public en général au: C.P.369 Cap-Chat, Cté Matane.Service 2 : Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) jusqu'à 5 tonnes pour le public en général au C.P.369 Cap-Chat, Cté de Matane.Service 3: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de plaisance, incluant station-wagon, pour le public en général à C.P.369 Cap-Chat, Cté Matane.Service 4: Location à long terme (un an et plus) de véhicules de plaisance incluant station-wagon pour le public en général à C.P.369 Cap-Chat, Cté Matane.IV \u2014 Avis de désistement: La Commission donne avis du désistement des requêtes par les requérants dans les affaires suivantes: QDW-68 M.RAOUL ALARIE Dossier: 201905 Désistement de la requête de transport par véhicule-taxi relative à la municipalité de Sullivan.57759-0 New application: The applicant requests the Québec Transport Commission to authorize it to provide the following vehicle-leasing services: Service 1: Short-term leasing (less than one year) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers up to 5 tons for the public at large at: Post Office Box 369, Cap-Chat, County of Matane.Service 2: Long-term leasing (one year or over) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors, trailers) up to 6 tons for the public at large at: Post Office Box 369, Cap-Chat, County of Matane.Service 3 : Short-term leasing (less than one year) of pleasure vehicles, including station-wagons, for the public at large ,at: Post Office Box 369, Cap Chat, County of Matane.Service 4: Long-term leasing (one year or over) of pleasure vehicles, including station-wagons, for the public at large, at: Post Office Box 369, Cap Chat, County of Matane.57759-0 IV \u2014 Notice of withdrawal : The Commission gives notice of withdrawal of applications by the applicants in the following proceedings: QDW-68 MR.RAOUL ALARIE File: 201905 Withdrawal of application concerning transport by taxicab, regarding the municipality of Sullivan.57759-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n\" 27 4901 V \u2014 Avis des décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation 2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.DECISIONS DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicant\tC page\tr.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-637\t19-06-74\t17824-V-P-l LOUIS-PHILIPPE GRAVEL\t4138\t01-06-74\tQ-1203\t La Commission: 1.Annule à toutes fins que de droit, la clause a: Transport restreint - service local - 2.Modifie la clause b en répétant la restriction qui y avait été apposée lors de l'émission du permis le 13 mai 1970; 3.Modifie la clause /; 4.Rédige une nouvelle codification des dispositifs et des décisions.The Commission: 1.Cancels, for all legal purposes, clause a: Restricted trucking - local service - 2.Modifies clause 6 by repeating the restriction which had been included therein at the time when the permit, dated May 13, 1970, was issued; 3.Modifies clause /; 4.Drafts a new codification of the enacting terms and decisions.QCR-638 20-06-74 Q-443-V-P-1 HARVEY TRANSPORT LIMITEE 3656 18-05-74 Q-1146 La Commission annule à toutes fins que de droit, le droit additionnel No 2 du permis 443-V.QCR-639 20-06-74 The Commission cancels, for all legal purposes, additional right No.2 of permit 443-V.Q-19459-V-P-1 GERARD BARON La Commission annule à toutes fins que de droit le service à contrat donné par le requérant pour le compte de Robert Déchênes.3655 18-05-74 Q-1146 The Commission cancels, for all legal purposes, the contract service provided by the application behalf of Robert Déchênes.QCR-640 20-06-74 Q-22498-V-P-1 LE DEMENAGEUR DU NORD LTEE La Commission : Revise sa décision QCR-546, du 25 avril 1974, et décrète le remboursement du montant de $25.00 déposé par Le Déménageur du Nord Ltée, au lieu de $50.00.4139 01-06-74 Q-1260 QCR-642 20-06-74 The Commission: Revises its decision QCR-546, dated April 26, 1974, and orders the reimbursement of the sum of $25.00, deposited by Le Déménageur du Nord Ltée, instead of $50.00.4138 01-06-74 7147-V-P-I L.THIBODEAU TRANSPORT INC.La Commission : The Commission : Modifie le paragraphe 2 de la décision QS-117, pour qu'il se lise comme suit: « Décrète la remise des cautionnements de $50.00 chacun effectué par le requérant L.Thibodeau Transport Inc., et l'opposant Dumont Express, par D.C.B.Industries Ltée.» Q-1251 Modifies paragraph 2 of decision QS-117.to read as follows: \"Orders the reimbursement of the deposits of 850.00 each, made by the applicant, L.Thibodeau Transport Inc., and by the opposing party, Dumont Express, by D.C.B.Industries Ltée.\" QCR-643 20-06-74 10-V-P-l GUILBAULT TRANSPORT INC.La Commission: Revise sa décision QCR-517 en modifiant le paragraphe 3 comme suit: \u2022 Décrète le remboursement du cautionnement de $75.00 effectué par Guilbault Transport Inc., selon l'arrêté en conseil 1275, ainsi que des cautionnements de $50.00 chacun faits par les deux opposantes, Michel Transport Inc., et V.Boutin Express Inc.» 4138 01-06-74 Q-1253 The Commission: Revises its decision QCR-517 by modifying paragraph 3 as follows: \"Orders the reimbursement of the deposit of $75.00 made by Guilbault Transport Inc., according to Order in Council 1275, and of the deposits of $50,00 each made by the two opposing parties, Michel Transport Inc., and V.Boutin Express Inc.\" QCR-644 20-06-74 22173-V-P-l CHO-BO INC.4138 01-06-74 Q-1252 4902 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6.1974, Vol.106, No.37 \t\t\tG.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tpage | date\tCase\t \t\tApplicants\t1\t\t La Commission : Revise sa décision QCR-S23 du 8 avril 1974 en y ajoutant le paragraphe suivant: « Décrète la confiscation du cautionnement de 850.00 effectué par l'opposante, Fox & Ginn Inc., celle-ci s'étant désistée (voir lettre du 1er novembre 1973).» The Commission: Revises its decision QCR-523 dated April 8, 1974 by adding thereto the following paragraph: \"Orders the confiscation of the deposit of $50.00 made by the opposing party, Fox & Ginn Inc.said company having withdrawn (see letter dated November 1 1973).\" QCR-645 20-06-74 3312-V-P-l CARON & FILS TRANSPORT INC.4139 01-06-74 Q-1262 La Commission: Revise sa décision QCR-533, paragraphe 2 comme suit: « Décrète la confiscation de la somme de $100.00 déposée par la requérante avec sa demande, conformément à l'arrêté en conseil 1275.» The Commission: Revises its decision QCR-533, paragraph 2 as follows: \"Orders the confiscation of the sum of $100.00 deposited by the applicant with its application, in conformity with Order in Council 1275.\" QPV-315 20-06-74 53-A-P-l TF AUTOBUS A.DROLET LTEE 3462 08-06-74 Q-1290 La Commission: Revise sa décision QS-323, relative tarifs.la modification de The Commission: Revises its decision QS-323, with regard to the tariff modification.QPV-316 20-06-74 692-A-P-l AUTOBUS LANDRY LIMITEE AUTOBUS FORTIN & POULIN INC.LEON CLOUTIER AUTOBUS FORTIN & POULIN INC.La Commission: Revise sa décision QPV-279 et décrète le remboursement des cautionnements suivants; Autobus Landry, $50.00; Léon Cloutier, $50.00, cautionnements effectués par Me Jacques Langlois, de l'étude Flynn, Rivard & Associés.4138 01-06-74 Q-1202 The Commission: Revises its decision QPV-279 and orders the reimbursement of the following deposits: Autobus Landry, $50.00; Léon Cloutier, $50.00, deposits made by Me Jacques Langlois, of Flynn, Rivard et Associés.QPV-318 20-06-74 3308-A-P-l VOYAGE DODDRYO ENRG.La Commission: Révoque à toutes fins que de droit, à la demande du détenteur, Voyages Doddryo Enrg.Mme Yolande B.Doddridge, le permis 3308-A.4362 08-06-74 Q-1291 QCV-8 20-06-74 The Commission: Cancels permit 3308-A, for all legal purposes, the request of the holder, Voyages Doddryo Enrg.Mrs.Yolande B.Doddridge.Q-54001-P-1 LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS-ARTISANS INC.La Commission: 1.Corrige sa décision QCV-1 TF et MCV-10-TF en date du 29 avril 1974.aux fins de décréter le remboursement du cautionnement de $50.00 effectué par Les Membres de L'Association Nationale des Camionneurs-Artisans Inc.2.Décrète la radiation, dans le dispositif de l'intervenante, l'Association des Constructeurs de Routes et Grands Travaux du Québec, cette intervenante n'ayant pas effectué de dépôt ou cautionnement.4139 01-06-74 Q-1263 The Commission: 1.Corrects its decision QCV-1 TF and MCV-10-TF dated April 29, 1974, for the purpose of ordering the reimbursement of the deposit of $50.00 made by Les Membres de L'Association Nationale des Camionneurs-Artisans Inc.2.Orders the deletion from the enacting terms, of the name of the following intervening party: l'Association des Constructeurs de Routes et Grands Travaux du Québec, which party-did not make any deposit.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS QPV-309\t17-06-74\t2750-A-D-G-2\t4923\t25-08-73\tQ-84 \t\tAUTOBUS LAVAL LTEE\t\t\t La Commission: 1.Prend acte des déclarations des parties; 2.Déclare le dossier clos à toutes fins que de droit.QPV-310 17-06-74 2584-A-D-l GUIDES OFFICIELS MONTMORENCY LTEE The Commission: 1.Takes notice of the statement of the parties; 2.Declares the file closed for all legal purposes.4922 25-08-73 Q-82 Rejetée / Rejected GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4903 No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QPV-311\t14-06-74\t2750-A-D-C-l COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE QUEBEC ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AUTOBUS\t4913\t25-08-73\tQ-100\t La Commission: 1.Prend acte de l'admission et de la déclaration de l'intimée; 2.Ordonne à l'intimée de cesser d'offrir les services pour lesquels elle ne détient pas de permis de la Commission et tels que décrits dans la circulaire du 24 mai 1973, d'arrêter la distribution et l'expédition de ladite circulaire et de détruire tous les exemplaires de ladite circulaire encore en sa possession.QPV-312 19-06-74 2667-A-D-l REAL DROLET Rejetée pour défaut de comparaître.QPV-313 19-06-74 2933-A-D-l AUTOBUS MENARD INC.Rejetée pour défaut de comparaître.The Commission: 1.Takes notice of the finding and the statement of the respondent ; 2.Orders the respondent to cease to provide the services described in the circular dated May 24, 1973, for which it does not hold a permit from the Commission, and to cease the distribution and forwarding of said circular, and to destroy all copies of the said circular that are still in its possession.19-01-74 j Q-558 Rejected for default 28 05-01-74 Q-633 Rejected for default SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS MPV-248-\t13-06-74\t602-A-D-5\t2496\t30-03-74\tM-\t-1385\tAccordée / Granted H\t\tSERVICE DE LIMOUSINE MURRAY HILL LT,EE\t\t\t\t\t MPV-249\t13-06-74\t543-A-D-l LEO BEAUREGARD & FILS LTEE\t2133\t16-03-74\tM-\t-1216\tDésistement Withdrawal MPV-250\t13-06-74\t2645-A-D-3\t7125\t01-12-73\tM\t-702\tAccordée / Granted \t\tPAQUETTE AUTOBUS INC.\t\t\t\t\t MPV-254-\t13-06-74\t720-A-MTF\t1924\t09-03-74\tM-\t-1192\tAccordée / Granted TF\t\tMAGOG AUTOBUS LTEE\t\t\t\t\t QCV-9\t20-06-74\tQ-502247\t3350\t04-05-74\tQ-\t1060\t \t\tM.JOSEPH POULIOT Requérant-vendeur / Applicant-vendor Q-502641 M.DENIS POULIOT Requérant-acquéreur Applicant-purchaser\t\t\t\t\t La Commission: 1.Autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Joseph Pouliot, en vertu de son attestation Q-502247; 2.Révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502247 ; 3.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Denis Pouliot, Armagh, Cté Bellechasse, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis; 4.Décrète le remboursement du cautionnement de $50.00 fait par Joseph Pouliot.conformément au règlement No 2.The Commission : 1.Authorizes the discontinuance of the bulk trucking service given by Joseph Pouliot, in virtue of its certificate Q-502247 ; 2.Cancels, for all legal purposes, certificate Q-502247 ; 3.Authorizes the issue of a certificate to the applicant-purchaser, Denis Pouliot, Armagh, County of Bellechasse which certificate shall\" not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit; 4.Orders the reimbursement of the 860.00 deposit made by Joseph Pouliot, in conformity with Regulation No.2.QPT-84 14-06-74 Q-201349-D-2 M.LUCIEN GUERARD Requérant-vendeur / Applicant-vendor M.ARTHUR MICHAUD Requérant-acquéreur Applicant-purchaser La Commission : 1.Révoque l'attestation délivrée au requérant-vendeur et autorise la suppression du service de transport par taxi donné par ce dernier.2.Délivre une attestation en faveur du requérant-acquéreur.3350 04-05-74 Q-1063 The Commission: 1.Cancels the certificate issued to the applicant-vendor and authorizes the discontinuance of the transport service by taxi-cab provided by the latter.2.Issues a certificate in behalf of the applicant-purchaser. 4904 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 No Date Requérants Applicants QPT-85 17-06-74 Q-24007-D-1 TF TF L'ASSOCIATION PROFESSION- NELLE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS Du QUEBEC INC.Modification de tarifs Modification of tariffs La Commission: 1.Prend et donne acte du désistement partiel quant à la période d'attente; 2.Accorde la requête telle qu'amendée et conformément a l'article 6.44 du règlement No 6, fixe les taux suivants: Transport par véhicule-taxi: a) au départ de la chute: $0.70 b) pour chaque mille parcouru: $0.60 c) pour chaque minute d'attente: $0.10 G.O.Q.page date 18-06-74 Cause Case Q-1184 Décisions The Commission: 1.Acknowledges and gives notice of the partial withdrawal as regards the waiting period; 2.Grants the request as amended and.pursuant to section 6.44 of Regulation No.6.fixes the following rates: Transport by taxi vehicle: (a) minimum departure tariff: $0.70 (fc) for each mile travelled: $0.60 (c) for each minute of waiting: $0.10 QPT-86 18-06-74 Q-24007-D-1 TF TF L'ASSOCIATION PROFESSION- NELLE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DU QUEBEC INC.La Commission: Accorde la requête et, conformément a l'article 6.44 du règlement No 6, fixe les taux suivants: Transport par véhicule-taxi.Groupe II.Agglomération A-25, Charlesbourg-Orsainville : a) $0.70 au départ de la chute; 5) $0.60 par mille parcouru; c) $0.10 par minute d'attente.3638 18-05-74 Q-1184-2 The Commission: Grants the request and, in conformity with section 6.44 of Regulation No.6, fixes the following rates: Transport by taxi vehicle, Group II, Conglomeration A-25 Charlesbourg-Orsainville : (a) $0.70 minimum departure tariff; (fc) $0.60 for each mile travelled; (c) $0.10 for each minute of waiting.QPT-87 18-06-74 Q-24007-D-1 TF L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DU QUEBEC INC.La Commission: Accorde la requête et, conformément à l'article 6.44 du règlement No 6, fixe les taux suivants: Transport par véhicule-taxi, Groupe II, Agglomération A-35, Lévis-Lauzon a) $0.70 au départ de la chute; 6) $0.60 du mille parcouru; c) $0.10 par minute d'attente.:)ï,:i-> 18-05-74 Q-1184-3 The Commission : Grants the request and, in conformity with section 6.44 of Regulation No.6, fixes the following rates: Transport by taxi vehicle.Group II, Conglomeration A-35, Lévis-Lauzon : (a) $0.70 minimum departure tariff; (6) $0,60 for each mile travelled; (c) $0.10 for each minute of waiting.QPT-88 TF 18-06-74 Q-24007-D-1 TF L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PROPRIETAIRES DE TAXIS DU QUEBEC INC.La Commission : Accorde la requête et.conformément à l'article 6.44 du règlement No 6, fixe les taux suivante: Transport par véhicule-taxi Groupe II.Agglomération A-38 Ste-Foy-Sillery: a) $0.70 au départ de la chute; 6) $0.60 du mille parcouru; c) $0.10 par minute d'attente.3638 18-05-74 Q-l 184-4 QPT-89 19-06-74 La Commission: The Commission: Grants the request and.in conformity with section 6.44 of Regulation No.6.fixes the following rates: Transport by taxi vehicle, Group II.Conglomeration A-38, Ste-Foy-Sillery: (a) $0.70 minimum departure tariff ; (5) $0.60 for each mile travelled; (c) $0.10 for each minute of waiting.Q-200440 ROBERT ROGER Requérant-vendeur / Applicant-vendor 200439 HONORE THIBEAULT Requérant-acquéreur Applicant-purchaser 1922 09-03-74 Q-830 1.Révoque l'attestation délivrée au requérant-vendeur et autorise la suppression du service de transport par taxi, donné par ce dernier.2.Délivre une attestation en faveur du requérant-acquéreur.The Commission: 1.Cancels the certificate issued to the applicant-vendor and authorizes the discontinuance of the transport service by taxicab provided by the latter.2.Issues a certificate in behalf of the applicant-purchaser. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 197/,, 106' année, n\" 27 4905 SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \tDate\tRequérants\t\t\tCause\t No\t\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t QCR-650\t21-06-74\t7277-V\t\t12-05-74\tRC-1144-\tAccordée / Granted TF\t\tTRANSPORT GAGNON & FRERES\t\t\tTFQ\t \t\tLTEE\t\t\t\t QCR-651\t27-06-74\t719-V D-l\t2999\t20-04-74\tQ-992\tAccordée / Granted \t\tLES DEMENAGEMENTS COTE LIMITEE\t\t\t\t QCR-652\t27-06-74\tQ-23610-V D-l\t2806\t13-04-74\tQ-977\tAccordée / Granted \t\tROSAIRE HARDY\t\t\t\t QCR-653\t27-06-74\tQ-22499-V D-4\t1543\t23-02-74\tQ-714\tAccordée / Granted \t\tLES TRANSPORTS DE LA BAIE\t\t\t\t \t\tD'HUDSON INC.\t\t\t\t QCS-333\t25-06-74\t23656-V D-l\t1689\t02-03-74\tQ-780\tAccordée / Granted \t\tJEAN-DENIS VACHON\t\t\t\t \t\tVoiturier-reraorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t1467-V\t\t\t\t \t\tTRANSPORT FRENETTE INC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QCS-334\t25-06-74\t937-V D-l\t3337\t04-05-74\tQ-1026\tAccordée / Granted \t\tCAUCHON, ELOI\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t7571-V\t\t\t\t \t\tMcMAHON TRANSPORT LTEE\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QCS-335\t25-06-74\t22928-V D-l\t1688\t02-03-74\tQ-773\tAccordée / Granted \t\tPATRICE VACHON\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t1467-V\t\t\t\t \t\tTRANSPORT FRENETTE INC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QCS-336\t25-06-74\tQ-23655-V-D-1\t1668\t02-03-74\tQ-775\tAccordée / Granted \t\tRICHARD DESILETS\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t1467-V\t\t\t\t \t\tTRANSPORT FRENETTE INC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QPV-321\t27-06-74\t3544-A D-2\t26\t05-01-74\tQ-524\tAccordée / Granted \t\tPAUL BOURQUE\t\t\t\t QL-158\t27-06-74\t1120-DYV D-l\t2807\t13-04-74\tQ-980\tAccordée / Granted \t\tMONTMAGNY DRIVE YOURSELF\t\t\t\t \t\tENRG.\t\t\t\t AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS QCR-649\t21-06-74\tQ-23563-V D-l\t1134\t02-02-74\tQ-637\tAccordée / Granted \t\tPOLY-FLEURS ENR.\t\t\t\t MCR-1016\t27-06-74\t1872-V POWELL TRANSPORT REG'D.\t2961\t12-05-73\tM-4325\tDésistement Withdrawal MCR-1018\t27-06-74\t6577-V D-2\t105\t12-01-74\tM-797\tAccordée / Granted MCR-1019\t\tASBESTOS EXPRESS LTEE\t\t\t\t \t27-06-74\t20430-V\t130\t12-01-74\tM-916\tRejetée / Rejected MCR-1024\t\tFRANCESCO AIELLO\t\t\t\t \t27-06-74\t1550-V D-2 H.LAPALME TRANSPORT LTEE\t7413\t15-12-73\tM-748\tAccordée / Granted MCR-1026\t27-06-74\t18510-V NORMAND CLOUTIER TRANSPORT INC.\t2449\t21-04-73\tM-4240\tDésistement Withdrawal 4906 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions MCR-1032 MCS-582 MCR-1033 MCR-1034 MCR-1035 MCS-563 MCR-1025 TF MCR-1027 MCR-1029 MCR-1030 MCS-552 TF MCS-553 TF MCS-584 TF MCS-558 MCS-559 MCS-660 MCS-664 MCS-565 TF MCS-566-TF ML-338\t27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 26-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74\t11929-V GODFROY PRIMEAU Requérant-vendeur / Applicant-vendor MAHEU TRANSPORT INC.Requérant-acquéreur Applicant-purchaser 8565\u2014V CENTRAL TRUCK LINES LTD.18449-V NOLET A FRERE TRANSPORT LTEE 19948-V BENJAMIN HEROUX 30003-D-18-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.6379-V D-l DAME PAULINE RICARD-FOURNIER Requérante-venderesse A pplicant-vendor NORBERT NORMANDIN Requérant-acquéreur Applicant-pu rchaser 30004-D-7-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOCIATION 30004-D-9-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASSOCIATION 22350-V D-l-TF WESTWAY FORWARDING LTD.15599-V-D-l-TF ZAVITZ BROTHERS LIMITED 22969-V-D-l-TF UNIK SOLVANT ENR'G.23658-V-D-l HITCHEN BRIAN Requérant / Applicant 17376-V-D-4 KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Requérante-conjointe / Joint applicant 23591-V-D-l GUY BRIEN Requérant/ Applicant 17376-V-D-5 KINGSWAY FREIGHT LINES LTD.Requérante-conjointe / Joint-applicant 15917-V MONTO FREIGHTWAYS LIMITED 16147-VM-D-l SHARPLEY THE MOVER (John Arnold Sharpley) Requérant-vendeur / Applicant-vendor SHARPLEY THE MOVER (Ludger Dubé) Requérant-acquéreu r Applicant-vurchaser 40003-D-4-TF CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASS'N.40003-S-41-TF CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASS'N.589-DY & 249-DYV BELAIR RENTAL SERVICE LTD.Mise en cause E.STERN L.COHEN J.LEVINE Requérants-vendeurs / Applicant-vendor\t118 2954 2400 3231 2504 2653 2501 2501 2330 3357 3357 2638 2638 3339 2493 2505 2506 4793\t12-01-74 12-05-73 21-04-73 26-05-73 30-03-74 06-04-74 30-03-74 30-03-74 23-03-74 04-05-74 04-05-74 06-04-74 06-04-74 04-05-74 30-03-74 30-03-74 30-03-74 18-08-73\tM-854 Q-643 Q-640 Q-644 M-1450 M-1568 M-I434 M-1453 M-1324 M-1747 M-1744 M-1505 M-1504 M-1712 M-1369 M-1451 M-1452 M-59\tAccordée / Granted Accordée / Granted Rejetée / Rejected Rejetée / Rejected Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée/ Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n\" 27 4907 No Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions ML-339 TF ML-340 TF ML-341 27-06-74 27-06-74 27-06-74 MPT-134 MPT-136 27-06-74 27-06-74 ML-136 ML-137 ML-138 ML-139 ML-140 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 27-06-74 KASSIE AUTOMOBILE INC.B.J.FINESTONE HEMPHREY KASSIE JACK COOKWELL Requérants-acquéreurs Applicant-purchaser 748-DY & 437-DYV-TF COMPACT RENT-A-CAR 10S-DYV & 533-DY-TF ARROW LEASING LTD.1138-DY & 8161-DYV-D-l FERNAND PERREAULT AUTOMOBILE INC.Requérante-venderesse Applicant-vendor LES LOCATIONS FERNAND PERREAULT INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser M-200136-D-1 LIONEL DEGUISE Requérant-vendeur / A pplicant-vendor M-205446-D-1 MARGUERITE DEGUISE Requérante-acquéreur Applicant-purchaser M-202700 ANDRE SAVIGNAC (Es-qualité d'exécuteur testamentaire de PAUL-EMILE SAVIGNAC) Requérant-vendeur / Applicant-vendor M-205814 ANDRE SAVIGNAC Requérant-acquéreur Applicant-purchaser M-203367 LEO SAGALA Requérant-vendeur / Applicant-vendor M-205538 PIERRE BIARD Requérant-acquéreur Applicant-purchaser M-203912 OSCAR GASCON Requérant-vendeur / Applicant-vendor RAYMOND LYRETTE Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser M-205296-D-10 JEAN-PAUL ROY Requérant-vendeur / Applicant-vendor M-205298-D-4 LES ENTREPRISES J.P.ROY INC Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser M-203963-D-1 RENE VINCENT Requérant-vendeur / Applicant-vendor M-205517-D-1 CLAUDE PELLAND Requérant-acquéreur Applicant-purchaser M-204636-D-1 RAYMOND CHARBONNEAU Requérant-vendeur / Applicant-vendor M-205489 YVON DESROCHERS Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser 3224 3225 1676 27-04-74 27-04-74 02-03-74 M-1757 M-1760 M-1131 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 2496 2651 2507 2507 2507 2507 2507 30-03-74 06-04-74 M-1392 M-1557 Accordée / Granted Accordée / Granted 30-03-74 30-03-74 30-03-74 30-03-74 30-03-74 M-1468 M-1469 M-1470 M-1471 M-1472 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 490S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974.Vol 106, No.27 No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\tI.O.Q.date\tCause Case\tDécisions MPV-268\t27-06-74\t3325-A-D-l B.& 3.C.BRUNET Requérant-vendeur / Applicant-vendor TRANSPORT MODELE INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser\t126\t12-01-74\tM-902\tAccordée / Granted PERMIS SPECIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-413 23782-V-S-l Q8-414 16076-V-S-I-A-l QS-415 TF 00002-MTF-5 QS-416 Q-503399-S-3 QS-417 Q-503399-S-4 Nom du requérant Name of Applicant M.VICTORIEN PERRON SIMPSON, COURTNEY A.ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AUTOBUS DU QUEBEC M.RAYMOND BROUILLARD M.RAYMOND BROUILLARD Validité: de: Validity Period Au 6 mai 1974 Until May 6.1974 Au 31 décembre 1974 ou décision finale de la Commission I Up to December 31, 1974 or pending final decision of the Commission.Au 25 octobre 1974 ou décision finale de la Commission I Up to October 26, 1974 °r pending final decision of the Commission.Au 25 octobre 1974 ou décision finale de la Commission / Until October 26.1974 or pending final decision by the Commission.Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions La Commission: 1) accueille la demande de permis spécial du requérant, et 2) somme Victorien Perron & Perron Transport ltée à comparaître devant elle le 29 août 1974, à 14 heures, au numéro 585 est, boulevard Charest, Québec, pour statuer sur la date d'expiration dudit permis spécial.The Commission: 1) Acknowledges the application for special permit from the applicant and, 2) Summons Victorien Perron & Perron Transport liée to appear before it on August 29, 1974, at 2 o'clock P.M., at 685 Charest Boulevard East.Québec City, in order to render a decision on the date of expiry of said special permit.Rejetée / Rejected.Permis spécial d'urgence émis pour changement de parcours, relatif à l'inondation de la Rivière Restigouche à Matapédia / Special emergency permit issued for a change of route, owing to the flooding of the Restigouche River at Matapédia.Accordée / Granted.Modification de tarifs / Modification of tariffs.Accordée / Granted.Transport en vrac, tourbe à gazon, catégorie entrepreneur, région No 4 / Bulk trucking, turf, contractor class.Region No.¦ Accordée / Granted.Transport en vrac, tourbe à gazon catégorie entrepreneur, région No 4 / Bulk trucking, turf, contractor class.Region No.4.Accordée / Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4909 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions QS-418 Q-503399-S-2 M.RAYMOND BROUILLARD QS-119 2522-A-S-l QS-420 TF Q-50009-S-1 TF QS-421 375-DYV-S-l QS-422 TF 16130-V-S1-TF QS-423 1543-A-S-l QS-424 1997-V-S-l POIRIER, JEAN-BAPTISTE LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES CAMIONNEURS-ARTISANS DE LA REGION 9 INC.HAUTERIVE DRIVE YOURSELF ENRG.MODERN TANK LINES INC.JACQUES ST-JACQUES INC.A.CLAVEAU TRANSPORT INC.QS-425 7041-V-S-5 TRANSPORT AMEDEE CAYER INC.Au 25 octobre 1974 ou décision finale de la Commission / Until October 26, 1974 or pending final decision by the Commission.Au 10 Septembre 1974 Until September 10, 1974.Au 31 mars 1975 Until March 31, 1976.Du 23 juin au 25 juin 1974 From June S3 to June 26, 1974.Au 31 décembre 1974 ou décision finale de la Commission / Until December SI, 1974 or pending final decision of the Commission.Transport en vrac, tourbe à gazon, catégorie entrepreneur, région No 4 / Bulk trucizing, turf, contractor class, Region No.4.Accordée / Granted.Visites touristiques par contrat, à l'intérieur du Parc Forillon, pour le compte de Parcs Canada, Ministère des Approvisionnements et Services / Contract sightseeing lours, within the limits of Forillon Park, on behalf of Canada Parks, Department of Supply and Services.Accordée / Granted.Modification de tarifs / Modification of tariffs.La Commission déclare ne pouvoir considérer la demande de la requérante / The Commission declares that it is unable to consider the applicant's request.Location à court terme de véhicules de commerce et de livraison (un camion) à 695, rue Puy-jallon, Hauterive./ Leasing of commercial and delivery vehicles (one truck) on a short-term basis at 696 Puyjallon Street, Hauterive.Sous l'autorité de l'article 2.70-1 du règlement 2, la Commission accorde la demande de modification de tarifs pour le transport d'huile et gazoline de Montréal à Drummondville (clause c) du permis 15130-V / Pursuant to section 2.70-1 of Regulation 2, the Commission grants the request for a modification of rates for the transport of oil and gasolene from Montreal to Drummondville (clause c) of permit 16130-V.Transport de passagers de la ville de Québec aux frontières du Québec à destination des Chutes Niagara, via Buffalo, le 23 juin 1974 et retour le 25 juin 1974 / Transport of passengers from Québec City to the Québec borders, point of destination: Niagara Falls, via Buffalo, on June 23,1974, and return on June 26,1974.(Deux (2) autobus) / (T^o (2) buses).Accordée / Granted.Transport restreint - longue distance - rayon -contrat - De Kénogami à tous endroits situés dans un rayon de 75 milles des limites de ladite cité, et retour, pour le transport de marchandises pour le compte de la Compagnie Price Limitée.Restricted trucking - long distance - radius - contract - From Kénogami to all points located within a radius of 75 miles from the limits of said Town, and return, for the transport of goods on behalf of Price Company Limited.Accordée / Granted.Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - De Rivière-Bleue aux frontières Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée sur les frontières des Etats du Maine, Vermont, New-York), pour le transport de bois, pour le compte de Les Cidres de Rivière Bleue.Destinationn : Tous les États des Etats-Unis et retour.Restricted trucking - long distance - restricted route - contract -From Rivière-Bleue to the Quebec-United States border (all ports of entry on the borders of the 4910 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.S7 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-426 1144-DYV-S-l QS-427 19304-V-S-5 QS-428 19304-V-S-6 QS-429 TF 15957-V-S-2 TF QS-430 15957-V-S-9 Nom du requérant Name of Applicant DORBEC INC.ST-LAMBERT TRANSPORT INC.ST-LAMBERT TRANSPORT INC.GERARD NOLIN LIMITEE GERARD NOLIN LIMITEE Validity Period Au 31 décembre 1974 / Until December SI, 1974 Au 31 décembre 1974 / Until December 31, 1974 Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions States of Maine, Vermont, New For*), for the transport of wood on behalf of Les Cidres de Rivière Bleue.Destination: AU States in the United States and return.Rejetée / Rejected Service 1: Location à court terme (moins d'une année) de véhicules commerciaux à 336, Avenue Centrale Val d'Or, P.Q.Service 2: Location à long terme (une année et plue) de véhicules commerciaux.Service 1: Leasing of commercial vehicles on a short-term basis (less than one year) at 336 Central Avenue, Val d'Or, P.Q.Service t: Leasing of commercial vehicles on a long-term basis (one year or over).Rejetée / Rejected Extension du permis 19304-V-S-3, se terminant le 18 juillet 1974: Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - De Montréal et de Québec à Port-Cartier et Sept-Iles, pour le transport de bois ouvré, pour le compte de Hébert Lumber Ltée.Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - De Montréal à Port-Cartier et Sept-Iles.pour le transport de contre-plaqué, pour le compte de Hébert Lumber Ltée / Ltd.Extension of permit 19304-V-S-S, ending July IS.1974: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From Montreal and Québec City to Port-Cartier and Sept-Iles, for the transport of dressed lumber on behalf of Hébert Lumber Ltée.Restricted trucking - long distance - restricted route \u2014 contract \u2014 From Montreal to Port-Cartier and Sept-Iles, for the transport of plywood on behalf of Hébert Lumber Ltée / Ltd.Accordée / Granted.Extension du permis 19304\u2014V-S-2, se terminant le 18 juin 1974 / Extension of permit 19304 -V-S-S, ending June 18, 1974.Accordée / Granted Modification de tarifs / Modification of tariffs Accordée / Granted Transport des gares du Canadien National et Canadien Pacifique situées à Matagami, Ville-Marie, Macamic, Rouyn, Lebel-sur-Quévillon, de calcium liquide par camion citerne, pour le compte de Allied Chemical Canada Ltd., pourvu que la détentrice en fasse l'épandage / Transport of liquid calcium, by tank truck, from the Canadian National and Canadian Pacific stations located in Matagami, Ville-Marie.Maca-mic, Rouyn, Lcbcl-6ur-QuèviUon, on behalf of Allied Chemical Canada Ltd., provided that the holder effect the spreading of said product.Rejetée / Rejected GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106- année, n° 27 4911 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validity Period Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions QS-431 23878-V-8-1 15957-V MS-4'.IG 297-DYV & 768-DY S-l MS-717 2645-A 8-7 MS-719 3458-A 8-1 M8-727 1332-V 23846-V 8-1 MS-728 232-V 8-3 MARCEL COTE Voiturier-remorqueur Haulaway operator GERARD NOLIN LTEE Voiturier-roulier / Carrier Cause - MRS-0204 RENTOMOBIL INC.Cause - 0063 PAQUETTE AUTOBUS INC.Cause -MRS-0157 ROBERT PAQUETTE AUTOBUS INC.Cause - MRS-0187 ATLAS TRUCKING CO.LTD.Requérante-venderesse Applicant-vendor EQUIPMENT EXPRESS LTD.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Cause -MRS-0215 J.E.FORTIN TRANSPORT INC.Au 31 décembre 1974 ou décision finale de la Commission Until December 81, 1974 or pending final decision by the Commission.Du 10 juin 1974 jusqu'au 8 juin 1975 ou jusqu'à décision finale / From June 10, 1974 to June8,1975 or pending final decision.24 juin, 13 juillet, 15 juillet, 3 août, 5 août et 24 août June 24, July IS, July 15, August 3, August 6, and August 24.Départ le 21 juin et retour le 1 juillet / Departure on June 21 and return on July t.Du 4 juin 1974 au 1er juin 1975 ou jusqu'à décision finale / From June 4, 1974, to June 1, 1975, or pending final decision.Du 7 juin 1974 au 5 juin 1975 ou jusqu'à décision finale From June 7, 1974, to June 6, 1976, or pending final decision.Marcel Côté est autorisé à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques de Gérard Nolin Ltée, selon les clauses a à i inclusivement, * à p inclusivement et r du permis 15967-V de cette dernière / Marcel Côté is authorised to haul with his duly-registered tractors, the trailers of Gérard Nolin Ltée, according to clauses a to i inclusive, k to p inclusive and 1 of permit 16967-V held by the latter.Autorise la requérante à opérer, à l'avenir, ses services autorisés par son permis actuel (297-DYV & 768-DY) à l'adresse de sa nouvelle place d'affaires, soit: Place Alexis Nihon, 1500 Atwater, Montréal, P.Que./ The applicant is authorized to operate, in the future, its services authorized by its present permit (297-DYV & 768-DY) at the address of its new place of business, that is: Place Alexis Nihon.1600 Atwater, Montreal, P.Qué.Accordée / Granted.6 voyages (3 véhicules et remorques à chacun dos voyages), de Montréal, Ste-Thérèse-Ouest, La-chute à destination du camp n Terre des Jeunes » situé à Montpellier (Papineau) et retour avec véhicules autobus et remorques pour bagages pour enfants et moniteurs, et ce pour le compte de « Terre des Jeunes Montpellier Inc.»l6 trips (S vehicles and trailers for each trip), from Montreal.Ste.Thérise-West.Lachute to \"Terre des Jeunes\" Camp located in Montpellier (Papineau) and return with buses and trailers for the transport of luggage belonging to campers and counsellors, on behalf of \"Terre des Jeunes Montpellier Inc.\" Accordée / Granted.Transport de scouts, de Montréal à St-Ambroise et Kénogami.pour le compte de l'association des scouts du Canada / Transport of boy scouts, from Montreal to St.Ambroise and Kénogami, on behalf of Canadian Boy Scouts Association.Accordée fGranted.Autorise la requérante-acquéreur d'opérer les clauses S.U et BB du permis 1332-V de la requérante-venderesse aux conditions réglementaires / A uthorizes the applicant-purchaser to operate clauses S, U and BB of permit 1SS2-V held by the applicant-vendor, in conformity with the prescribed conditions.Accordée / Granted.De Lacolle à Montréal-Métropolitain, et retour From Lacolle to Greater Montreal, and return.Accordée / Granted. 4912 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS 71».23864-V S-l MS-730 3718-V S-l 167-DYL MS-731-TF 602-A MTF-7 MS-740 1976-V S-2 MS-741 1443-A S-l MS-742 3191-A S-l Nom du requérant Name of Applicant Cause-MRS-0228 BURNS FOOD (TRANSPORT) LTD.Cause -MRS-0190 PAUL LAFRANCE TRANSPORT INC.Partie requérante / Applicant JOHNSON & JOHNSON LIMITED Requérante-conjointe Joint applicant Cause-MRS-0238 SERVICE DE LIMOUSINE MURRAY HILL LTEE LACAILLE (ROUVILLE) TRANSPORT INC.Cause-MRS-0213 JACQUES FLEURENT Cause - MRS-0T74 ALBERT BRAUTL & FILS INC.Validité: de:.à: Validity Period Du 4 juin 1974 au 2 juin 1975 ou jusqu'à décision finale From June 4.1974.to June S, 1975.or pending final decision.Du 5 juin 1974 au 3 juin 1975 ou jusqu'à décision finale From June 6, 1974, to June S.1975, or pending final decision.La présente décision entrera en vigueur à l'expiration des délais légaux / This decision shall come into effect upon (he expiry of the legal time limit.Jusqu'au 18 juin 1974 / Until June 18.1974.Du 21 juin au 21 août 1974.From June il to August 21, 1974.Entre le 1er juin et le 1er novembre 1974.Between June 1 and November 1, 1974.Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions a) De la frontière Québec - Ontario, tous les ports d'entrée à tous points de la province de Québec et retour, pour le transport de produits alimentaires pour le compte de Burns Food Ltd., (Destination en Ontario: Kitchener), from the Québec - Ontario border, ail ports of entry to all points located in the Province of Québec, and return, for the transport of food products on behalf of Burns Food Ltd., (Point of destination in Ontario: Kitchener).Accordée / Granted.a) Montréal et tous les endroits situés sur l'Ile de Montréal et tous les endroits situés en dehors de l'Ile de Montréal mais ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville / From Montreal and all points located on the Island of Montreal, and all points located outside the Island of Montreal, but within a distance of 6 miles from the limits of said city.Accordée / Granted.Autorise la modification des tarifs du transport entre l'Aéroport International de Montréal (Dorval) et Montréal, en vertu de l'article 2.71 du règlement No 2/ Authorizes modification of the transport rates between the Montreal International Airport (Dorval) and Montreal, pursuant to section 2.71 of Regulation No.2.Accordée / Granted.De St-Jean Baptiste de Rouville à la frontière Québec - Nouveau-Brunswick (port d'entrée: Ste-Rose du Dégelis); pour transporter 75 voyages de viandes congelés avec remorques réfrigérées, au port de St-Jean, Nouveau-Brunswick.Marchandise originant de Québec Poultry Ltd.et destinée à Cuba / From St.Jean Baptiste de Rouville to the Québec - New-Brunswick border (port of entry: Ste.Rose du Dégelis); for the transport of 75 truck-loads of frozen meat, by refrigerated trailers, to the harbour of St.John, New-Brunswick.Goods originating from Québec Poultry Ltd.and bound for Cuba.Accordée / Granted.Transport d'enfants et moniteurs du Lac Brûlé Camp Hiawatha Inc., à tout endroit situé dans un rayon de 50 milles dudit Lac, et retour et ce par contrat avec le Camp Hiawatha Inc., en date du 6 mai 1974 / Transport of children and counsellors from Lac Brûlé Camp Hiawatha Inc., to any point located within a radius of 60 miles from said Lake, and return, in conformity with a contract with Camp Hiawatha Inc., dated May6, 1974.Accordée / Granted.Transport d'environ 200 étudiants résidant à Beauharnois et ce sur les fermes maraîchères de Sherrington.Ste-Clothilde et St-Urbain.Ce transport est effectué pour le compte du Centre de la Main-d'Oeuvre du Canada / 7>an»porf of about 200 students residing in Beauharnois to the market farms of Sherrington, Ste.Clothilde and St.Urbain.This transport service shall be provided on behalf of Canada Manpower Center.Accordée / Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G juillet 1974, 106' année, ?i° 27 4913 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tValidité: Nom du requérant\tde:.à: Name of Applicant\tValidity \tPeriod Cause - MRS-0223\tJusqu'au 1er JOHN N.BROCKLESBY\tdécembre TRANSPORT LTD.\t1974 / Until \tDecember 1, \t1974.Cause - MRS-0229\tDu 11 juin 1974 THOMAS W.BAILLIE\tau 9 juin 1975 Voiturier-remorqueur\tou jusqu'à Haulaway-operator JOH N-BROCKLESB Y\tdécision finale \tFrom June 11, TRANSPORT LTD.\t1974, to June Voiture-roulier\t9, 1976, or Carrier\tpending final \tdecision.Cause - MRS-0124\tJusqu'au 5 ALFRED LANCIAULT\tseptembre \t1974/(0 \tSeptember 6, \t1974.ROBERT MAILLOUX\tAu 1er septembre \t1974/ Until \tSeptember 1, \t1974 AUTOBUS CODERE INC.\t LES TRANSPORTS DE LA\t BAIE D'HUDSON INC.\t Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions MS-743 8123-V S-10 MS-744 23862-V S-l 8123-V MS-745 23794-V S-l QS-432 Q-23838-V-S-1 QS-433 TF 3281-A-MTF-l QS-434 Q-22499-V-S-5 Location à court terme de deux (2) remorques-citernes de Brazeau Transport Inc.(6793-V) et ce suivant contrat çn date du mois de juin 1974 / Short-term leasing of two (2) tank trailers from Brazeau Transport Inc.(6793-V) according to a contract dated June 1974.Marque Modèle Make Model Fruehauf H1B-X3W-1300 No de série Serial Number DXS-543-301 DXS-643-302 Accordée / Granted.Autorisation de remorquer, avec ses tracteurs dûment enregistrés, les remorques vides ou remplies du voiturier-roulier: John N.Brocklesby Transport Ltd., dans les cadres du permis 8123-V, selon toutes les clauses du permis de cette dernière et pour son compte J Authorization to haul, with his duly registered tractors, the trailers, empty or loaded, belonging to the carrier: John N.Brocklesby Transport Ltd., under the terms of permit 8123-V, according to all clauses of the latter's permit, and on its behalf.Service de courtier en transport pour le transport de marchandises autorisé par son permis de voiturier-roulier No 8123-V, selon toutes les clauses, en utilisant les services de remorquage de Thomas W.Baillie appelé voiturier-remorqueur / Transport service broker for the transport of goods authorized by its carrier's permit No.8123-V, according to all clauses, utilizing the haulaway services of Thomas W.Baillie, designated as haulaway operator.Accordée / Granted.Livraison d'engrais chimique aux cultivateurs situés dans un rayon de 35 milles de Mont St-Grégoire.comté Iberville / Delivery of fertilizer to farmers residing within a radius of 36 miles from Mont St.Grégoire, County of Iberville.Accordée / Granted.Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - équipement spécialisé - De Labrieville à Foresville, pour le transport, par équipement spécialisé de maisons et garages, pour le compte de Marc Savard.Restricted trucking-long distance-restricted route-contract - special equipment - From Labrieville to Forestville, for the transport of houses and garages, with special equipment, on behalf of Marc Savard.Accordée / Granted La Commission des transports du Québec accorde la présente demande de modification de tarifs.The Québec Transport Commission grants the present request for modification of tariffs.Transport restreint - longue distance - rayon - De Fort George à tous les points du territoire de la Société de Développement de la Baie James, et retour, pour le transport d'explosifs et substituts d'explosifs dans des camions spécialement agencés à cette 6n.Restricted trucking - long distance - radius - From Fort George to all points in the territory of the James Bay Development Corporation, and return, for the transport of explosives ajnd substitutes of explosives, in trucks specially equipped for this purpose.Rejetée / Rejected 4914 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6.1974, Vol 106, No.27 No du repertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-435 Q-22499-V-S-1 QS-436 23829-V-SIA-l QS-437 22950-V-S-l QS-438 1336-DY-S-l QS-439 443-V-S-3 QS-440 1306-AT-S-l \tValidité: Nom du requérant\tde:.à: Name of Applicant\tValidity \tPeriod LES TRANSPORTS DE LA BAIE\t D'HUDSON INC.\t MESSAGERIE CNR.\tX compter du 7 \tmai 1974 pour \tune période de \t30 jours / From \t7 of May 1974 \tfor a period of \tSO days.MESSAGERIE D'ALMA ENRG.\t GARAGE ROBERT GAGNON\t & FILS LTEE\t HARVEY TRANSPORT\t LIMITEE / HARVEY\t TRANSPORT LIMITED\t RENAUD, ALAIN\tAu 31 décembre \t1974 / Until \tDecember SI, \t1974 Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions 1.Transport restreint - longue distance -rayon - De Fort George à tous les points du territoire de la Société de Développement de la Baie-James, et retour.2.Transport restreint - longue distance - territoire - De tous points à tous autres points dans le territoire de la Société de Développement de la Baie James, et retour.1.Restricted trucking - long distance - radius -From Fort George to alt points in the territory of the James Bay Development Corporation, and return.2.Restricted trucking - long distance -territory -From all points to all other points within the territory of the James Bay Development Corporation, and return.Rejetée / Rejected Conformément au règlement 2.76-3 vu situation d'urgence créée par inondation, autorisation accordée pour transporter par remorque les expéditions de Consolidated Bathurst C, entre New-Richmond et frontières N ou veau-Bru ns-wick destination Campbellton port d'entrée Pointe à la Croix./n conformity with Regulation 2.75-8, considering the emergency state created by flood, authorization is granted to transport the shipments of Consolidated Bathurst C, by trailer, between New Richmond and the New Brunswick border, destination: Campbellton, port of entry: Pointe-à-la-Croix.Transport pour le compte de Harvey Transport Limitée de marchandise générale.Ledit transport se fera conformément au permis par la Commission des transports pour le compte de Messagerie d'AJma Enrg.Transport of general goods on behalf of Harvey Transport Limitée.Said transport shall be effected in conformity with the permit issued by the Transport Commission on behalf of Messagerie a\"Alma Enrg.Rejetée / Rejected Service de location à court terme (moins d'une année) de véhicules de plaisance, incluant station-wagon.Short-term leasing (less than one year) of pleasure vehicles, including station wagons.Rejetée / Rejected Requérir les services de Messagerie d'Alma Enrg.pour délivrer les colis légers et urgents.Ledit transport se fera conformément au permis émis à ce transporteur.Cette demande est pour une période de six mois.Requests the strvices of Messagerie d'Alma Enrg.to deliver light parcels requiring immediate delivery.Said transport shall be effected in conformity with the permit issued to this carrier.This request is for a period of six months.Rejetée / Rejected Service aéroportuaire, modification de terminus nécessitée par les travaux effectués à l'aéroport de Bagotville.Airport service, change of terminal necessitated by the works effected at the Bagotville Airport.Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1971,, 106' année, n° 27 4915 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tValidité: de:.à: Validity Period\tDétails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions QS-441-TF 2716-A-MTF-l\tCHAMPLAIN CITY TOURS REG'D.(Bertrand Cayer)\t\tSous l'autorité de l'article 2.71 du règlement 2, la Commission fixe les taux et tarifs de transport de personnes par autobus de la requérante comme suit: 1.Service Bernière et St-Nicolas pour visite de Québec: $7,00 2.St-Romuald et Lévis pour visite de Québec: $8.00 3.Beauport parc de roulottes et motel pour visite de Québec: $9.00 4.Pour Ste-Anne-de-Beaupré: $12.00 Pursuant to section 2.71 of Regulation 2, the Commission fixes the following rates and tariffs for the transport of persons by bus operated by the applicant.1.Service between Bernière and St.Nicolas for a lour of Québec City: S7.00 2.St.Romuald and Levis for a tour of Quebec City: $8.00 3.Beauport trailer park and motel for a tour of Québec City: 19.00 4.For SU.Anne-de-Beaupré: 112.00 SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS TRANSPORT DE MATIERES EN VRAC / TRANSPORT OF BULK MATERIAL No\tDate QCV-101\t06-06-74 QCV-102\t06-06-74 QCV-103\t06-06-74 QCV-104\t07-06-74 QCV-105\t07-06-74 QCV-106\t07-06-74 QCV-107\t07-06-74 QCV-108\t07-06-74 QCV-109\t07-06-74 QCV-110\t07-06-74 QCV-111\t07-06-74 QCV-112\t07-06-74 QCV-113\t07-06-74 QCV-114\t07-06-74 QCV-115\t07-06-74 Requérant A pplicant Demande de permis\t\t\t Application for permit\t\tCause\tDécisions \t\t\t Catégorie\t\tRoll\t \tRégion\t\t Class\t\t\t Artisan\t9\tQV-0001\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0002\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0003\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-O004\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0005\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0006\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0007\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0008\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0009\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0010\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0011\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0012\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0013\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0014\tAccordée / Granted Artisan\t9\tQV-0015\tAccordée / Granted Q-500005 D-001 JEAN-CLAUDE CHENEL Q-500425 D-001 CHARLES LESSARD Q-500426 D-001 EDGARD MERCIER Q-500427 D-001 CLAUDE LIZOTTE Q-500428 D-001 LAUREAT LESSARD Q-500428 D-002 LAUREAT LESSARD Q-500429 D-001 MICHEL MERCIER Q-500431 D-001 IRMA MORIN Q-500433 D-001 LAURENT LALANCETTE Q-500434 D-001 CLERMONT PARENT Q-500435 D-001 OMER OUELLETTE Q-500436 D-001 LUCIEN OUELLET Q-500437 D-001 ADEODAT NORMAND Q-500438 D-001 AUGUSTIN NOEL Q-500439 D-001 LIONEL ARSENEAULT 4916 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July G, 1974, Vol.106, No.27 No\tDate\tRequérant Applicant\tDemande Applicatioi Catégorie Cuut\tde permis i for permit Région\tCause Roll\tDécisions QCV-116 QCV-117 QCV-118 QCV-119 QCV-120 QCV-121 QCV-122 QCV-123 QCV-124 QCV-125 QCV-126 QCV-128 QCV-129 QCV-130 QCV-131 QCV-132 QCV-127 QCV-133 QCV-134 QCV-136 QCV-136 QCV-137 QCV-138 QCV-139 QCV-140 QCV-141 QCV-142 QCV-143 QCV-144 QCV-145 QCV-146 QCV-147 QCV-148 QCV-149\t07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 12-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 12-06-74 12-06-74 07-06-74 12-06-74 07-06-74 12-06-74 07-06-74 12-00-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07-06-74 07 06 71 07-06-74 07-06-74 20-06-74 07-06-74\tQ-500440 D-O01 PHILIPPE ARNAUD Q-500442 D-001 RAYMOND MIVTLLE Q-500448 D-O01 LORENZO THIBEAULT Q-500449 D-001 WILLIE SAINT-PIERRE Q-500443 D-001 CLAUDE BOURQUE Q-500444 D-001 EUGENE TREMBLAY Q-500445 D-001 MAJORIC LAPIERRE Q-500446 D-001 JEAN-LOUIS BEAUDOUIN Q-500447 D-001 GEORGES BEAUDIN Q-500451 D-001 WILFRID POULIN Q-500453 D-001 THOMAS-LOU IS DRAPEAU Q-500455 D-001 ARMAND BOULAY Q-500456 D-001 RAYMOND BOUCHER Q-500457 D-001 CYRILLE BOLDUC Q-500458 D-001 MARCEL BERUBE Q-500459 D-001 MARC-ANDRE BERUBE Q-600454 D-001 FERNAND BOULAY Q-500460 D-001 LEO BERNATCHEZ Q-500461 D-001 A LCI DE BELLEFONTAINE Q-500462 D-001 ERNEST BEAULIEU Q-500464 D-001 ARTHUR LABRECQUE Q-500466 D-001 ALDEGE GAGNON Q-500467 D-001 ARISTIDE GALLANT Q-500468 D-001 PETER FERGUSON Q-500470 D-001 GEORGES DUBE Q-500472 D-001 MARIO LANGLAIS Q-501873 D-001 ARTHUR LAFONTAINE Q-501874 D-001 JOSEPH DUFOUR Q-501875 D-001 GASTON H.BOUCHARD Q-501876 D-001 PAUL TREMBLAY Q-501878 D-001 WELLIE TREMBLAY Q-501880 D-001 PATRICK SAVARD Q-501881 D-001 CAMIL TREMBLAY Q-501882 D-001 JOS ELIE LA VOIE\tArtisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Aftisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan\t9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9\tQV-0016 QV-0017 QV-0018 QV-0019 QV-0021 QV-0022 QV-0023 QV-0024 QV-0025 QV-0026 QV-0027 QV-0029 QV-0030 QV-0031 QV-0032 QV-0033 QV-0028 QV-0034 QV-0035 QV-0036 QV-0037 QV-O038 QV-0039 QV-0040 QV-0041 QV-0042 QV-0043 QV-0044 QV-0045 QV-0046 QV-0047 QV-0048 QV-0049 QV-0060\tAccordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4917 \t\t\tDemande de permis\t\t\t \t\tRequérant\tApplication for permit\t\tCause\t No\tDate\t\t\t\t\tDécisions \t\tApplicant\tCatégorie\t\tRoll\t \t\t\t\tRégion\t\t \t\t\tClass\t\t\t QCV-150\t07-06-74\tQ-501883 D-001\t\t\t\t \t\tROSAIRE SIROIS\tArtisan\t9\tQV-0051\tAccordée / Granted QCV-151\t07-06-74\tQ-501884 D-001\t\t\t\t \t\tYVAN DESMEULES\tArtisan\t9\tQV-0052\tAccordée / Granted QCV-152\t07-06-74\tQ-501886 D-001\t\t\t\t \t\tBENOIT GAGNON\tArtisan\t9\tQV-0053\tAccordée / Granted QCV-153\t07-06-74\tQ-501887 D-001\t\t\t\t \t\tNORMAND MURRAY\tArtisan\t9\tQV-0054\tAccordée / Granted QCV-154\t07-06-74\tQ-501888 D-001\t\t\t\t \t\tRAYMOND PERRON\tArtisan\t9\tQV-0055\tAccordée / Granted QCV-155\t07-06-74\tQ-501889 D-001\t\t\t\t \t\tLEON SIMARD\tArtisan\t9\tQV-0056\tAccordée / Granted QCV-156\t07-06-74\tQ-501890 D-001\t\t\t\t \t\tHENRI-PAUL LEPAGE\tArtisan\t9\tQV-0057\tAccordée / Granted QCV-157\t07-06-74\tQ-501891 D-001\t\t\t\t \t\tMARIUS LABRIE\tArtisan\t9\tQV-O058\tAccordée / Granted QCV-158\t07-06-74\tQ-501893 D-001\t\t\t\t \t\tMARTIAL FOSTER\tArtisan\t9\tQV-0059\tAccordée / Granted QCV-159\t07-06-74\tQ-501897 D-001\t\t\t\t \t\tPAUL TREMBLAY\tArtisan\t9\tQV-0060\tAccordée / Granted QCV-160\t07-06-74\tQ-501898 D-001\t\t\t\t \t\tROBERT MAILLOUX\tArtisan\t9\tQV-0061\tAccordée / Granted QCV-161\t07 06 74\tQ-501899 D-001\t\t\t\t \t\tANNETTE CANUEL\tArtisan\t9\tQV-0062\tAccordée / Granted QCV-162\t07-06-74\tQ-501900 D-001\t\t\t\t \t\tREMY PERREAULT\tArtisan\t9\tQV-0063\tAccordée / Granted QCV-163\t07-06-74\tQ-501901 D-O01\t\t\t\t \t\tJEAN-CLAUDE DES-\tArtisan\t9\tQV-O064\tAccordée / Granted \t\tCHENES\t\t\t\t QCV-164\t07-06-74\tQ-501902 D-001\t\t\t\t \t\tJEAN-GUY BRISSON\tArtisan\t9\tQV-0065\tAccordée/ Granted QCV-165\t07-06-74\tQ-501903 D-001\t\t\t\t \t\tJ.-CLAUDE CHIASSON\tArtisan\t9\tQV-0066\tAccordée / Granted QCV-168\t07-06-74\tQ-501905 D-O01\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tBERTRAND GAGNON\tArtisan\t9\tQV-0067\t QCV-167\t07-06-74\tQ-501906 D-001\t\t\t\t \t\tROMAIN PLOURDE\tArtisan\t9\tQV-0068\tAccordée / Granted QCV-168\t07-06-74\tQ-501908 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tPIERRE MIGNEAULT\tArtisan\t9\tQV-0069\t QCV-169\t20-06-74\tQ-501910 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tSYLVAIN LELIEVRE\tArtisan\t9\tQV-0070\t QCV-170\t20-06-74\tQ-501911 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tLUCIEN CARON\tArtisan\t9\tQV-0071\t QCV-171\t07-06-74\tQ-501915 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tBERTRAND COTE\tArtisan\t9\tQV-0072\t QCV-172\t07-06-74\tQ-501916 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tMAJELLA HARVEY\tArtisan\t9\tQV-0073\t QCV-173\t07-06-74\tQ-501917 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tBERTRAND GAGNON\tArtisan\t9\tQV-0074\t QCV-174\t07-06-74\tQ-501917 D-003\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tBERTRAND GAGNON\tArtisan\t9\tQV-0075\t QCV-175\t07-06-74\tQ-501918 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tLEONAJRD LEFRANÇOIS\tArtisan\t9\tQV-0076\t QCV-176\t07-06-74\tQ-501920 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tYVON LAVOIE\tArtisan\t9\tQV-0077\t QCV-177\t07-06-74\tQ-501921 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tPAUL DESCHENES\tArtisan\t9\tQV-0078\t QCV-178\t07-06-74\tQ-502155 D-001\t\t\tQV-0079\tAccordée / Granted \t\tGERARD LEBEL\tArtisan\t9\t\t QCV-179\t07-06-74\tQ-502156 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tADRIEN RINGUETTE\tArtisan\t9\tQV-0080\t QCV-180\t07-06-74\tQ-502158 D-001\t\t\tQV-0081\tAccordée / Granted \t\tJEANNOT TREMBLAY\tArtisan\t9\t\t QCV-181\t07-06-74\tQ-502159 D-001\t\t\tQV-0082\tAccordée / Granted \t\tADRIEN LAROUCHE\tArtisan\t9\t\t QCV-182\t07-06-74\tQ-502160 D-001\t\t\t\tAccordée / Granted \t\tGILBERT MICHAUD\tArtisan\t9\tQV-0083\t QCV-183\t07-06-74\tQ-502161 D-001\t\t\tQV-0084\tAccordée / Granted \t\tJEAN-CLAUDE FORTIN\tArtisan\t9\t\t 4918 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 No\tDate QCV-184\t07-06-74 QCV-185\t07-06-74 QCV-186\t07-06-74 QCV-187\t07-06-74 QCV-188\t07-06-74 QCV-189\t07-06-74 QCV-190\t07-06-74 QCV-191\t07-06-74 QCV-192\t10-06-74 QCV-193\t10-06-74 QCV-194\t10-06-74 QCV-195\t10-06-74 QCV-196\t10-06-74 QCV-197\t10-06-74 QCV-198\t20-06-74 QCV-199\t10-06-74 QCV-200\t10-06-74 QCV-201\t10-06-74 QCV-202\t10-06-74 QCV-203\t10-06-74 QCV-204\t10-06-74 QCV-205\t10-06-74 QCV-206\t10-06-74 QCV-207\t11-06-74 QVC-208\t20-06-74 QCV-209\t13-06-74 QCV-210\t12-06-74 QCV-211\t11-06-74 QCV-212\t11-06-74 QCV-213\t11-06-74 QCV-214\t11-06-74 QCV-215\t20-06-74 QCV-216\t12-06-74 QCV-217\t12-06-74 Requérant A ppticant Q-S02162 D-001 CONKAD THERIAULT Q-502210 D-001 JOSEPH GAGNON Q-502744 D-001 CLEMENT GOUDREAU Q-502745 D-001 FLORIAN SAVARD Q-502745 D-002 FLORIAN SAVARD Q-502746 D-001 LORENZO DESCHENES Q-502747 D-001 FERNANDO DESCHENES Q-502886 D-001 JOSEPH MIMEAULT Q-503062 D-001 TONY (ANTOINE) BOND Q-503114 D-001 ALFRED SAINT-GELAIS Q-503137 D-001 JEAN-PHILIPPE LAVOIE Q-503253 D-001 LUCIEN TREMBLAY Q-503254 D-001 MAURICE GAGNON Q-503255 D-001 JOSEPH DECHESNES Q-503258 D-001 LAURENT TREMBLAY Q-503262 D-001 JOSEPH-EMILE BOUCHER Q-503263 D-001 PAUL-AIME BELANGER Q-503264 D-001 JEAN-CLAUDE JEAN Q-503392 D-001 GUY TRUCHON Q-503417 D-001 MARCEL POIRIER Q-503781 D-001 VALERE DEROY Q-503957 D-001 BERNARD GAGNON Q-504037 D-001 MARC LAUZIER Q-501907 D-001 JOSEPH DANAIS Q-500140 D-001 LEONARD BEAULIEU Q-503359 D-001 CAMILLE DEVOST Q-500073 D-001 MICHEL MILLER Q-500076 D-001 FERNAND HARRISON Q-500079 D-001 GLORIAN HARRISON Q-500083 D-001 VICTOR TREMBLAY Q-500083 D-002 VICTOR TREMBLAY Q-500085 D-001 GERMAIN DESBIENS Q-500089 D-001 AIME DUFOUR Q-500090 D-001 JEAN-MARIE OUELLET Demande de permis Application for permit Catégorie Cla» Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Artisan Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Région Cause Roll QV-0085 QV-0086 QV-0087 QV-0088 QV-0089 QV-0090 QV-0091 QV-0092 QV-0093 QV-0094 QV-0095 QV-0096 QV-0097 QV-0098 QV-0099 QV-0200 QV-O201 QV-0202 QV-0203 QV-0204 QV-0205 QV-0206 QV-0207 QV-0208 QV-0209 QV-0210 QV-0100 QV-O101 QV-0102 QV-0103 QV-0104 QV-0105 QV-0106 QV-0107 Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granttd Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n\" 27 4919 No\tDate\tRequérant Applicant\tDemande Application Catégorie Claee\tde permis for permit Région\tCause Roll\tDécisions QCV-218\t12-06-74\tQ-500093 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tHENRI GAUDREAULT\tneur\t9\tQV-0108\tAccordée / Granted QCV-219\t12-06-74\tQ-500093 D-002\tEntrepre-\t\t\t \t\tHENRI GAUDREAULT\tneur\t9\tQV-0109\tAccordée / Granted QCV-220\t12-06-74\tQ-500095 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tJEAN-CHARLES TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0110\tAccordée / Granted QCV-221\t12-06-74\tQ-500096 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tMARIUS LEVESQUE\tneur\t9\tQV-0111\tAccordée / Granted OCV-222\t12-06-74\tQ-500097 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tANDRE DUCHESNE\tneur\t9\tQV-0112\tAccordée / Granted QCV-223\t12-06-74\tQ-500099 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tHENRI-PAUL MARTEL\tneur\t9\tQV-0113\tAccordée / Granted QCV-224\t12-06-74\tQ-500102 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tLIONEL DESCHENES\tneur\t9\tQV-0114\tAccordée / Granted QCV-225\t12-06-74\tQ-500106 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tBERCHMANS TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0115\tAccordée / Granted QCV-226\t20-06-74\tQ-500109 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tGUY DUMAS\tneur\t9\tQV-0116\tAccordée / Granted QCV-227\t12-06-74\tQ-500111 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tMARCEL BOUCHARD\tneur\t9\tQV-0117\tAccordée / Granted QCV-228\t12-06-74\tQ-500112 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tPIERRE-PAUL PELLETIER\tneur\t9\tQV-0118\tAccordée / Granted QCV-229\t12-06-74\tQ-500123 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tROLAND MUNGER INC.\tneur\t9\tQV-0119\tAccordée / Granted QCV-230\t12-06-74\tQ-500123 D-002\tEntrepre-\t\t\t \t\tROLAND MUNGER INC.\tneur\t9\tQV-0120\tAccordée / Granted QCV-231\t12-06-74\tQ-500123 D-003\tEntrepre-\t\t\t \t\tROLAND MUNGER INC.\tneur\t9\tQV-0121\tAccordée / Granted QCV-232\t12-06-74\tQ-500123 D-OOS\tEntrepre-\t\t\t \t\tROLAND MUNGER INC.\tneur\t9\tQV-0122\tAccordée / Granted QCV-233\t12-06-74\tQ-500127 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tLEONARD NORMAND\tneur\t9\tQV-0123\tAccordée / Granted QCV-234\t12-06-74\tQ-500127 D-002\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tLEONARD NORMAND\tneur\t9\tQV-0124\t QCV-235\t12-06-74\tQ-500127 D-003\tEntrepre-\t\t\t \t\tLEONARD NORMAND\tneur\t9\tQV-0125\tAccordée / Granted QCV-236\t12-06-74\tQ-500128 D-001\tEntrepre-\t\t\t \t\tTHOMAS LS TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0126\tAccordée / Granted QCV-237\t12-06-74\tQ-500128 D-002\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tTHOMAS LS TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0127\t QCV-238\t12-06-74\tQ-500128 D-003\tEntrepre-\t\t\t \t\tTHOMAS LS TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0128\tAccordée / Granted QCV-239\t12-06-74\tQ-500131 D-001\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tGERARD TREMBLAY\tneur\t9\tQV-0129\t QCV-240\t12-06-74\tQ-500137 D-001\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tCLAUDE GAGNON\tneur\t9\tQV-0130\t QCV-241\t12-06-74\tQ-500139 D-001\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tRAOUL POIRIER\tneur\t9\tQV-0131\t QCV-242\t12-06-74\tQ-500348 D-001\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tRENE MALENFANT\tneur\t9\tQV-0132\t QCV-243\t12-06-74\tQ-500924 D-001\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT COBEC LTEE\tneur\t9\tQV-0133\t QCV-244\t12-06-74\tQ-500924 D-002\tEntrepre-\t\tQV-0134\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT COBEC LTEE\tneur\t9\t\t QCV-245\t12-06-74\tQ-500924 D-002\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT COBEC LTEE\tneur\t9\tQV-0135\t QCV-248\t12-06-74\tQ-501001 D-001\tEntrepre-\t\tQV-0136\tAccordée / Granted \t\tCIE METAL SAGUENAY\tneur\t9\t\t QCV-247\t12-06-74\tINC.Q-501002 D-002\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tCIE METAL SAGUENAY rvtp\tneur\t9\tQV-0136\t QCV-248\t12-06-74\tQ-501003 D-001\tEntrepre-\t\tQV-0137\tAccordée / Granted \t\tPAUL VEILLETTE\tneur\t9\t\t QCV-249\t12-06-74\tQ-501003 D-002\tEntrepre-\t\t\tAccordée / Granted \t\tPAUL VEILLETTE\tneur\t9\tQV-0139\t QCV-250\t12-06-74\tQ-501004 D-001\tEntrepre-\t\tQV-0140\tAccordée / Granted \t\tANSELME LEVESQUE\tneur\t9\t\t 4920 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 QCV-251\t12-06-74 QCV-252\t11-06-74 QCV-253\t11-06-74 QCV-254\t11-06-74 QCV-255\t11-06-74 QCV-2S6\t11-06-74 QCV-257\t12-06-74 QCV-258\t12-06-74 QCV-259\t11-06-74 QCV-260\t11-06-74 QCV-261\t12-06-74 QCV-262\t12-06-74 QCV-263\t12-06-74 QCV-264\t13-06-74 QCV-265\t13-06-74 QCV-266\t11-06-74 QCV-267\t13-06-74 QCV-268\t13-06-74 QCV-269\t13-06-74 QCV-270\t13-06-74 QCV-271\t13-06-74 QCV-272\t13-06-74 Date Requérant Applicant Q-501006 D-001 PAUL-EMILE EMOND Q-501008 D-001 MEDERIC GAGNON Q-501009 D-001 EMILE LEPAGE Q-501013 D-001 DAMIEN ROSS Q-501014 D-001 MARIUS DALLAIRE Q-501016 D-001 BERNADIN ROSS Q-501016 D-003 BERNADIN ROSS Q-501018 D-001 LUCIEN TREMBLAY Q-501024 D-001 LAURENT GAUTHIER Q-501025 D-001 JEAN-PHILIPPE BOUCHARD Q-501026 D-001 GAETAN LEVESQUE Q-501026 D-003 GAETAN LEVESQUE Q-501026 D-003 GAETAN LEVESQUE Q-501027 D-001 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-002 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-003 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-004 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-O06 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-007 NAPOLEON BROCHU INC.Q-501027 D-008 NAPOLEON BROCHU Q-501028 D-001 EUGENE MILLER Q-501029 D-001 ROBERT D'ASTOUS Demande de permis Application for permit Catégorie Class Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Entrepreneur Région Cause Roll QV-0141 QV-0142 QV-0143 QV-0144 QV-0145 Q-0146 QV-0147 QV-0148 QV-0149 QV-0150 QV-0151 QV-0152 QV-0153 QV-0154 QV-0155 QV-0156 QV-0157 QV-0158 QV-0159 QV-0160 QV-0161 QV-0162 Décisions Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée Accordée / Granted I Granted I Granted I Granted I Granted I Granted I Granted I Granted I Granted I Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 57759-0\t Changement de nom \u2014 Loi du\tChange of name \u2014 Act Demandes\tApplications Michel Brougham\tMichel Brougham Michel Brougham, résidant et domicilié au 5557, rue St-.Iacques, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret permettant de changer son nom en celui de Michel Ustiniuk.Montréal, ce 21e jour de mai 1974.Le procureur du requérant, 57769-27-2-0 Anoré Bibbau.Michel Brougham, residing and domiciled at 5557, St-Jacques Street, in the city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to that of Michel Ustiniuk.Montreal, this 21 day of May 1974.AnDHÊ BlBEAU, 57769-27-2-o Attorney for the Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 27 4921 Steven Michael Garfinkle Avis est par les présentes donné que Steven Michael Garfinkle, étudiant, demeurant au numéro 4667, chemin Côte-Sainte-Catherine, en les ville et district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Steven Michael Garnell.Montréal, le 30 mai 1974.Les procureurs du requérant, 57736-26-2 Pascal, Cohen & Devine.Steven Michael Garfinkle Notice is hereby given that Steven Michael Garfinkle, student, residing at 4667 Côte St.Catherine Road, in the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Steven Michael Garnell.Montreal, May 30th, 1974.Pascal, Cohen & Devine, 57736-26-2-0 Attorneys for petitioner.Gilles Demers Avis est donné que Gilles Demers, célibataire, majeur, domicilié au 15635 Bellerive, app.202, Pointe-aux-Trembles.district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec, en vue d'obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Gilles Demers Villeneuve.Montréal, ce 4 juin 1974.Le procureur du requérant, 57737-26-2-0 Hélène Leduc.Gilles Demers Notice is hereby given that Gilles Demers, bachelor, of the legal age of majority, domiciled at 15635 Bellerive, Apt.202, Pointe-aux-Trembles, District of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for a decree of the Lieutenant-Governor in Council, changing his name to Gilles Demers Villeneuve.Montreal, June 4th, 1974.Hélène Leduc, 57737-26-2-0 Attorney for the company.Gary Arthur Chrystal Avis est donné que Gary Arthur Chrystal, résidant au 885, 43e avenue, LaSalle, P.Q., district de Montréal, adresse une requête au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Gary Arthur Crothers.Montreal, ce 19 juin 1974.Les procureurs du requérant, Ogilvy, Cope, Pobteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault.57770-27-2-o Par: Jean A.Savard.Gary Arthur Chrystal Notice is given that Gary Arthur Chrystal, residing at 885-43rd Avenue, LaSalle, P.Q., district of Montreal, will present an application to the Minister of Justice to change his name to Gary Arthur Crothers.Montreal, this 19th day of June, 1974.Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Per: Jean A.Savard, 57770-27-2 Attorneys for the Petitioner.Serge Grenon Serge Grenon, domicilié et résidant au 265, rue Gordon, à Verdun, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, de la province de Québec, pour obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Line Grenon.Montréal, ce 22 mai 1974.Le procureur de la requérante, 57771-27-2-0 André Bibeau.Serge Grenon Serge Grenon.domiciled and residing at 265 Gordon, in Verdun, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to that of Line Grenon.Montreal, this 22 May 1974.André Bibeau, 57771-27-2-0 Attorney for the Petitioner.Nicola Zappavigna Avis est par les présentes donné que Nicola Zappavigna, technicien en aviation, de la ville de Montréal, province de Québec, y résidant au 8431, rue St-Denis, appartement B, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec afin d'obtenir un décret du lieutenant-gouverneur en conseil changeant son nom de Nicola Zappavigna en celui de Nicolas Morrel.Que ledit décret n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Dorval, Québec, ce 21e jour de juin 1974.Les procureurs du requérant, 57775-27-2 Amaron & Stead.Nicola Zappavigna Notice is hereby given that Nicola Zappavigna, Aircraft Technician, of the City of Montreal, Province of Québec, therein residing at 8431 St.Denis Street, Apartment B, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for a decree of the Lieutenant-Governor in Council for the change of his name from Nicola Zappavigna to Nicolas Morrel.That the said decree will affect no person other than the applicant.Dorval, Québec, this 21st, day of June, 1974.Amaron and Stead, 57775-27-2-0 Attorneys for the Applicant. 4922 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July G, 1974, Vol.10G, No.27 Joseph Jean-Paul Hussul Avis est donné par les présentes que Joseph Jean-Paul Hussul.de la cité de Montréal-Nord, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin de changer son nom de Joseph Jean-Paul Hussul en celui de John Steele.Montréal, le 14 juin 1974.Les procureurs du requérant, 57772-27-2 Lechter & Segal.Joseph, Louis, Orastide Jolivet Avis est donné que Joseph, Louis, Orastide Jolivet, mineur, domicilié au 1210 Hrébeuf à Trois-Rivières, dudit district, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtention d'un décret changeant ses nom et prénom en ceux de Joseph, Louis, Aristide Jolivin.Trois-Rivières, ce 20 juin 1974.Les procureur du requérant, Langevin, Vigeant, 57773-27-2-0 Ayotte & Crête.Jambur Venkatasubbaiah Anantharamaiah Avis est par les présentes donné que Jambur Venka-tasubbaiah Anantharamaiah, phychiatre.domicilié au 315 avenue Glengarry, Ville Mont-Royal, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Jambur Ananth.Ce changement sera applicable également à son épouse dame Kamala Anantharamaiah et à son enfant mineur Karlik.Montréal, ce 25 juin 1974.Les procureurs du requérant, Duquet, Mackay, Weldon, 57774-27-2-0 Bronstetter & Tiiivierge.Joseph Robert Richard Perron Avis est par les présentes donné que Joseph Robert Richard Perron, présentement domicilié à Lucerne, district de Hull, province de Québec, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom pour celui de Joseph Robert Richard Dugas./.es procureurs du requérant, 57805-27-2-o Hamon, Dupour & Isabelle, avocats.Joseph, Jean-Paul Hussul Notice is hereby given that Joseph Jean-Paul Hussul, of the City of Montreal North, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of Québec, to change his name from Joseph Jean-Paul Hussul to John Steele.Montreal, June 14, 1974.Lechter & Segal, 57772-27-2-o Attorneys for the Petitioner.Joseph, Louis, Orastide Jclivct Notice is hereby given that Joseph, Louis, Orastide Jolivet.miner, residing at 1210 Brébeuf Street, in the City cud District of Trois-Rivières, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his first name and surname to Joseph, Louis, Aristide Jolivin.Trois-Rivières, this 20th day of June, 1974.Langevin, Vigeant, Ayotte & Crête, 57773-27-2-o Attorneys for the Petitioner.Jambur Venkatasubbaiah Anantharamaiah Notice is hereby given that Jambur Venkatasubbaiah Anantharamaiah, Psychiatrist, domiciled at 315 Glengarry Avenue, Town of Mount-Royal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the granting of an order changing his name to that of Jambur Ananth.This change will also benefit his wife Dame Kamala Anantharamaiah, as well as his minor son Kartik.Montreal, this 25th day of June 1974.Duquet, Mackay, Weldon, Bronstetter & Thi vierge, 57774-27-2-0 Attorneys for the Petitioner.Joseph Robert Richard Perron Notice is hereby given that Joseph Robert Richard Perron, presently domiciled at Lucerne, district of Hull, province of Québec, intends to present a petition before the Lieutenant-Governor in Council in order to obtain a decree permitting him to change his name to Joseph Robert Richard Dugas.Hamon, Dufour & Isabelle, Barristers, 57805-27-2-o Attorneys for petitioner.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Marie Georgette Bernier Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2098 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Marie Georgina Bernier en celui de Marie Georgette Bernier.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Change of name \u2014 Act Granted Marie Georgette Bernier It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Georgina Bernier to that of Marie Georgette Bernier, by order number 2098, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c.57763 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106- année, n\" 27 4923 Patricia Ann Carrier Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2099 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Patricia Ann Bryson en celui de Patricia Ann Carrier.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Joseph Edmond Vianncy Côté Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2100 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Joseph-Edmond Côté en celui de Joseph Edmond Vianney Côté.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Mary Jo Holland Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2101 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Marie Regina Yvette Violette Taylor en celui de Mary Jo Holland.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-o Robert Normand, c.r.Léon Vahan Lemian Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2102 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Leon Vahan Melemetdjian en celui de Léon Vahan Lemian.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Roland Leroux Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2103 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Joseph Aimé Roger en celui de Roland Leroux.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Irving Rocke Ransen Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2104 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Issie Socoransky en celui de Irving Rocke Ransen.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Patricia Ann Carrier It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Patricia Ann Bryson to that of Patricia Ann Carrier, by order number 2099, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice.Joseph Edmond Vianney Côté' It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Edmond Côté to that of Joseph Edmond Vianney Côté, by order number 2100, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c.57763 Deputy Minister of Justice.Mary Jo Holland It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Regina Yvette Violette Taylor to that of Mary Jo Holland, by order number 2101, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice.Léon Vahan Lemian It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Leon Vahan Melemetdjian to that of Léon Vahan Lemian, by order number 2102, dated June 12,1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice.Roland Leroux It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Aimé Roger to that of Roland Leroux, by order number 2103, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice.Irving Rocke Ransen It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Issie Socoransky to that of Irving Rocke Ransen, bv order number 2104, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice. 4924 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Allan li;n -(in Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2105 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Elijah Resnikoff en celui de Allan Rayson.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Serge Vasilach Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2106 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Serge Vasilache en celui de Serge Vasilach.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Allan Rayson It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Elijah Resnikoff to that of Allan Rayson, by order number 2105, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of Justice.Serge Vasilach It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to chtnge the name of Serge Vasilache to that of Serge Vasilach, by order number 2106, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.57763 Robert Normand, q.c, Deputy Minister of Justice.Helen Williams Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2107 du 12 juin 1974, d'effectuer le changement de nom de Marie Lucille Jeannine Lari-vière en celui de Helen Williams.Québec, le 25 juin 1974.Le sous-ministre de la justice, 57763-0 Robert Normand, c.r.Helen Williams It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Lucille Jeannine Larivière to that of Helen Williams, by order number 2107, dated June 12, 1974.Québec, June 25, 1974.Robert Normand, q.c, 57763 Deputy Minister of justice.Demandes à la Législature Applications to Legislature Beaucage Ltée Avis est donné que Jean Beaucage, Henri de la Fresnaye, Jacques Beaucage, Noël Simoneau et Elf Hydrocarbures du Québec Ltée s'adresseront à l'Assemblée nationale du Québec pour faire adopter un projet de loi corrigeant les lettres patentes confirmant un acte d'accord fusionnant en une seule corporation sous le nom de Beaucage Ltée les anciennes corporations Beaucage Ltée et Les Pétroles Cloutier Ltée.57792-27-2-0 Les procureurs des requérants, Lapointe, Rosenstein & KoNICSBERC.Beaucage Ltée Notice is hereby given that Jean Beaucage, Henri de la Fresnaye, Jacques Beaucage, Noël Simoneau and Elf Québec Hydrocarbons Ltd.shall apply to the Québec National Assembly for the adoption of a Bill correcting the letters Patent confirming an amalgamation Agreement amalgamating Beaucage Ltée and Les Pétroles Cloutier Ltée into one new company undei the name of Beaucage Ltée.57792-27-4-0 Lapointe, Rosenstein & KoNIGSBERG, Attorneys for petitioners.Hillmack Services Ltd.Prenez avis que monsieur Gaétan Chabot, avocat, demeurant et domicilié au numéro 99 avenue du Chalet, à Ville St-Pierre, district de Montréal, s'adressera à l'Assemblée nationale, à sa présente session dans le but de faire adopter un projet de loi privée révoquant la dissolution et l'annulation de la charte de la compagnie, Hillmack Services Ltd.Ville LaSalle.le 27e jour de juin 1974.57806-27-4-o Gaétan Chabot, avocat.Hillmack Services Ltd.Notice is given that Mr Gaétan Chabot, lawyer, residing and domiciled at 99 Du Chalet, avenue, in Ville St.Pierre, district of Montreal, will apply to the National Assembly at its present session to request the passing a private bill revoquing the dissolution and the annulment of the charter of Hillmack Services Ltd.City of LaSalle, this 27th day of June, 1974.57806-27-4-o Gaétan Chabot, Lawyer. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° 37 4925 Cité de Hull Avis public est, par les présentes, donné que la Cité de Hull s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi, sur la matière suivante: 1.Pour autoriser la Cité de Hull à signer avec la Municipalité Régionale d'Ottawa-Carleton une convention lui permettant d'acquérir et/ou louer, et/ou obtenir, et/ou exploiter un système de contrôle des feux de circulation par ordinateur, lequel système desservira aussi le territoire de la Cité.2.Pour autoriser la Cité de Hull à permettre à la Municipalité Régionale d'Ottewa-Carleton de demander des soumissions publiques pour l'installation et l'entretien dudit système de contrôle des feux de circulation.Donné à Hull, ce 6 jour de juin 1974.57613-24-4-0 Le greffier, Robert LeSage, o.m.a.City of Hull Public notice is, hereby, given that the City of Hull will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act, for the following purpose: 1.To authorize the City of Hull to sign with the Ottawa-Carleton Regional Municipality a convention permitting to acquire, and/or rent, and/or obtain, and/or exploit a computer traffic signal system; which system will also operate in the City of Hull territory.2.To authorize the City of Hull to permit the Ottawa-Carleton Regional Municipality to call for public tenders for the installation and maintenance of said computer traffic signal system.Given at Hull, this June 6th, 1974.Robert LeSage, c.m.o., 57613-24-4-0 The City Clerk.Régie de l'assurance-maladie du Québec Québec Health Insurance Board Liste par région de noms et adresses d'affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d'exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci, publiée conformément à l'article 7.01 des règlements concernant la Loi de Passurance-maladie, adoptés par arrêté en conseil No 27, en date du 6 janvier 1971.List compiled on a regional basis, of the names and business addresses of professionals who intend practising their profession outside the scope of the plan as professionals or who have ceased to practice in this capacity, as well as the date on which their withdrawal of non-participation becomes effective or ceases to become effective, published according to section 7.01 of the regulations respecting the Health Insurance Act adopted by order in council No.27, dated January 6, 1971.Professionnels désengagés Professionals withdrawn Médecins omnipraticiens General Practitioners Date effective du désengagement Effective date of withdrawal Région de Montréal \u2014 Montreal Region Duchesne, Laurent, 75, boul.Dorchester ouest, Bureau 1017, Montréal 128, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Mino, Roland, Case postale 7395, Québec 7, (Québec) Tremblay, Jacques, 590, Saint-Cyrille ouest, Québec 6, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Chamard, John McLean, 1509, Sherbrooke West, Suite 18A, Montréal 109, (Québec) Edmison, Ralph Staples, 1414 Drummond, Montreal (Québec) H3G 1W1 Lamb, Roland Thomas, 1414 Drummond, suite 1121 Montréal (Québec) H3G 1W1 29-01-71 30-05-71 23-05-71 16-08-72 12-04-74 15-06-74 4926 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.26 Professionnels non participants Non-participating professionals Dale effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins spécialistes Medical Specialists Region de Montréal \u2014 Montreal Region Almudevar, Manuel, 612, St.John's Road, Suite 114, Pointe-Claire 720, (Québec) Aronovitch, Michael, 4119, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) Barker, Charles S., 9, Nelson, Montréal 263, (Québec) Black, Donald Kenneth, Case postale 95, Hudson Heights, (Québec) Bossé, Jean, 6555, boul.Gouin ouest, Montréal 389, (Québec) Boulanger, Jean-Baptiste, 3610, avenue Atwater, Montréal 109, (Québec) Brabander, Joachim, 1390, Sherbrooke Street West, Montréal 109, (Québec) Brow, Georges-Raymond, 1374, Sherbrooke Street West, Suite 7, Montréal 109, (Québec) Browman, Mark, 7841 - 2nd Avenue, Montréal 455, (Québec) Butler, Albert-A., Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) Cantero, Antonio, 1396, Sainte-Catherine ouest, Montréal 107, (Québec) Copping, Gordon A., 724, Upper Belmont Avenue, Montréal 217, (Québec) Cordeau, Claire, 1392, Jean-Talon est, #301, Montréal 329, (Québec) David.Paul-P., 8705, rue Barbeau, Montréal 457, (Québec) Dawson, Howard L., 14 Bellevue Avenue, Westmount 217, (Québec) Dumais, Gaston, 12245, Grenet, Suite 112, Montréal 390, (Québec) Eakin, W.W., 1538, Sherbrooke Street West, Apartment 704, Montréal 109, (Québec) Fullerton, C.W., 1414, Drummond Street, Montréal 107, (Québec) Gélinas, André, 565, Javelin, Dorval 740, (Québec) Genest, Armand, 30, boulevard St-Joseph est, Suite 818, Montréal 151, (Québec) Gibbard, Bruce A., 4324 Sherbrocke West, suite 48, Montréal (Québec) H3Z 1E1 Gold, Michael M.A., 5785, Côte des Neiges, Apartment 105, Montréal 249, (Québec) Hunt, Brian R., 1538, Sherbrooke West, Apt.622, Montréal 109.(Québec) Johnston, Kenneth B., Main Road, Hudson, Vaudreuil (Québec) Korenberg, Lela C, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 601, Montréal 109, (Québec) Korenberg, Morton, Medical Arts Bldg., Montréal 109, (Québec) Kravitz, Henry, 4994, Circle Road, Montréal 248, (Québec) Larivière, Paul, 3484, avenue Laval, Montréal 130, (Québec) Legendre, J.-Henri, 969, boul.Saint-Joseph est.Appartement 3, Montréal 176, (Québec) Levy, Léonard, 3545, Côte des Neiges, app.118, Montréal 109, (Québec) Macdonald, Allison D., 3550, Côte des Neiges, Suite 110, Montréal 109, (Québec) MacFarlane, Malcolm R., 1538, Sherbrooke Street West, Apt.601, Montréal 109, (Québec) Maguire, J.Gordon, 4485, Sherbrooke ouest, Westmount, Montréal 215, (Québec) Manseau, J.Arthur, 960, boulevard Saint-Joseph est, Montréal 176, (Québec) Mason, Edward Halton, 3465, Côte des Neiges Road, Suite 81, Montréal 109, (Québec) Melhado, Gérald Carlton, 900, Sherbrooke Street West, Montréal 110, (Québec) Moll, Albert Edward, 3550, Côte des Neiges Road, Suite 570, Montréal 109, (Québec) Montgomery, Lome C, 556, Grosvenor Avenue, Montréal 217, (Québec) Morin, Paul, 680, Saint-Denis, Saint-Hyacinthe, (Québec) Nadler, Norman-J\u201e 4141, Sherbrooke Ouest, #540, Montréal 215, (Québec) Naiman, James, 4330, Sherbrooke ouest, Montréal 215, (Québec) Neil, Feeney, 1414, Drummond, Montréal.(Québec) Nerman, Yale, 1115, Sherbrooke West, Suite 1403, Montréal 110, (Québec) Pearson, Georges J.R., 5715, avenue Darlington, Appartement 1, Montréal 251, (Québec) Robert, Paul, 3489, avenue Atwater, Appartement 6, Montréal 109, (Québec) Scott, W.Clifford M., 1260, McGregor Avenue, Suite 405, Montréal 109, (Québec) Smith, Clifton Conway, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1020, Montréal 109, (Québec) Smith, Frederick Mclver, 3550, Côte des Neiges, Suite 640, Montréal 109, (Québec) Stein, Samuel, 1025, Pine Avenue West, Montréal 112, (Québec) Tucker, Elrie Clifford, 1390, Sherbrooke Street West, Apt.2, Montréal 109, (Québec) Wood, David John, 4119 Sherbrooke West, Westmount, Montreal (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Lapointe, Donat, 220, Grande-Allée est, app.650, Québec 4, (Québec) Larue, Lucien, 964, Casot, Québec 6, (Québec) Parrot, Paul, 1328, avenue des Pins, Sillerv, Québec 6, (Québec) 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-12-70 24-09-72 16-04-71 01-12-70 01-12-70 30-07-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 06-01-73 01-12-70 01-12-70 27-03-71 15-01-71 01-12-70 01-12-70 29-01-71 30-06-74 01-12-70 03-01-73 31-12-70 26-08-72 01-12-70 10-06-72 01-12-70 01-12-70 06-04-73 01-12-70 26-08-72 13-02-71 01-12-70 07-01-71 01-01-71 25-04-72 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-03-72 27-04-74 03-01-71 01-12-70 03-02-71 01-12-70 01-12-70 01-12-70 01-07-72 01-12-70 17-05-74 13-01-71 26-12-70 01-12-70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106' année, n° S7 4927 Professionnels non participants Non-participating professionals Date effective de non-participation Effective date of non-participation Médecins omnipraticiens Genera) Practitioners Région de Montréal \u2014 Montreal Region Archambault, Paul-A., 2805, Willowdale, Montréal 250, (Québec) Brouillé, Raynald, 3775, Saint-Hubert, Appartement 10, Montréal 132, (Québec) Chèvrefils, Paul-E., 7960, Saint-Denis, Montréal 327, (Québec) Cholette, Albert M., 5001, Gamier, Montréal, (Québec) Gordon, Lionel, 6235A, Lennox Avenue, Montréal 251, (Québec) Jacques, Elphège, 190, rue Principale est, Farnham, (Québec) Joannette.Jean-Paul, 4930, Mayfair, Montréal 265, (Québec) Mayman, Abe, 5845, Côte des Neiges, Suite 690, Montréal 249, (Québec) Ostiguy, Jean-Paul, 450, rue Sherbrooke est, Suite 108, Montréal 132, (Québec) Scott, Benjamin H., 5146, Westbury Avenue, Montreal 248, (Québec) Vines, Norman M., 1452, Bishop Street, Suite 3, Montréal 107, (Québec) Région de Trois-Rivières \u2014 Trois-Rivières Region Marcotte, Gaston, Case postale 457, Cap-de-la-Madeleine, (Québec) Région de Québec \u2014 Québec Region Leclaire, Yves, 2832, Valccurt, Québec 10 (Québec) Rinfret, Charles-G., 3179, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, Québec 10, (Québec) Samson, J.W., 725, 68e Rue est, Québec 7, (Québec) Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Grainger, Thomas R., Case postale 1500, John Manville Clinic, Asbestos, Richmond, (Québec) Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Région de Montréal \u2014 Montreal Region Beaulieu, J.-Edouard, Case postale 148, Saint-Rémy, Napierville, (Québec) Bieniecki, Irena, 531, Rockland Avenue, Montréal 153, (Québec) Bourgoin, Jean-Charles, 1248, rue Lajoie, Montréal 154, (Québec) Bourke, Edward T., 18, Thornhill Avenue, Westmount 217, (Québec) Boyles, Williams Howard, 1414, Drummond Street, Suite 422, Montréal 107, (Québec) Burns, Frank Léonard, 1414, Drummond Street, Suite 1022, Montréal 107, (Québec) Bushell, Winston C, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 1006, Montréal 109, (Québec) Caplan, Herbert, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 912 - 913, Montréal 109, (Québec) Casaubon, Jacques, 2100.Jean-Talon est, Montréal 329 (Québec) Coen, Irving, 43 Donegani Avenue, Pointe-Claire (Québec) Colle, Albert Joseph, 5253, boul.Décarie, Suite 218, Montréal 248, (Québec) DeGrandmont, Claude, 4934, rue Adam, Montréal 404, (Québec) De la Fuente, Lucio N., 1000, Jean-Talon est, Montréal (Québec) H3N 1T1 Deschesnes, G.H., 2900 Édouard-Mcntpetit, #A245, Montréal 250 (Québec) Diner, Murray H., 5757.Decclles, #336, Montréal, (Québec) Dundass, Georges M., 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Dundass, Roberta Phelps, 4545, Sherbrooke, Montréal 215, (Québec) Elo, James Thomas, 1414, Drummond Street, Suite 909, Montréal 107, (Québec) Franklin, Gérald, 4078, Gage Road, Montreal 218, (Québec) Gendron, Roland, 900 Sherbrooke ouest, Suite 12, Montréal 110, (Québec) Geoftïion, Roland, 48, Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) Haie, George H., 465 Victoria Avenue, St-Lambert (Québec) Harvey, Robert-F., 1650, Cedar Avenue, Montréal 109, (Québec) Henry, Donald Ward, 227, Kenaston Avenue, Montreal 305, (Québec) Kent, Léonard E., 4695, Sherbrooke Street West, Montréal 215, (Québec) Kimura, Akira, 1538 Sherbrooke West, Montreal (Québec) Kitzman, Ernest-Abraham, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 410, Montréal 109, (Québec) 01-05-71 02-01-71 13-12-70 01-01-74 15-01-72 01-12-70 01-12-70 17-12-70 01-12-70 22-07-71 01-12-70 21-10-71 01-12-70 13-12-70 27-07-72 01-12-70 30-03-71 02-09-72 15-04-71 09-03-71 02-03-71 13-02-71 10-02-71 11-01-73 30-06-74 21-06-74 03-02-71 08-04-72 30-05-74 G0-C6-74 26-04-74 03-A3-73 29-10-73 16-02-71 19-11-72 07-03-73 20-06-74 29-06-74 15-04-71 31-01-71 07-04-71 31-05-74 01-02-71 4928 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Professionnels non participants Non-participating professionals Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Dale effective de non-participation Effective date of non-participation Région de Montréal \u2014 Montreal Region Labelle, Hubert, 666, Sherbrooke, ouest, #501, Montréal 111, (Québec) 10-07-74 Labelle, Paul, 11271, Henri d'Arles, Montréal 389 (Québec) 11-08-71 Lafleui, Roland, 250, avenue Willibrod, Verdun (Québec) 06-06-74 Lafortune, Jean-Paul, 5704, Laurendeau, Montréal 205, (Québec) 13-02-71 I.alanne, Jean-Guy, 719, 1ère Rue, Iberville, (Québec) 17-01-73 Lamarche, Roger, 6119, Monkland, Montréal (Québec) 13-01-74 Larue, Charles Arthur, 6746, St-Denis, Montréal 327 (Québec) 21-06-74 Lawlor, Robert, 333, chemin Rune-Marie, Montréal 247, (Québec) 18-02-71 Lefebvre, Pierre-I., 2225, boulevard Lapinière, Ville Brassard, (Québec) 02-02-71 Lefort, Guy, 42, Principale est.Ste-Agathe-des-Monts (Québec) 20-06-74 Legault, J.-Victor, 5757, Decelles, #336, Montréal 251, (Québec) 01-12-73 .Marchand.Paul-R., 1006, Medical Arts Building, Montréal (Québec) H3G 1L5 03-05-74 Mathieu, Leopold, 1103, boul.St-Jcseph est, Montréal 176 (Québec) 15-06-74 Munro, David John, 3550, Côte des Neiges, #400, Montréal (Québec) 07-12-73 Muroff, Frederick, 1414, Drummond Street, Suite 1104, Montréal 107, (Québec) 10-03-71 Myles, Thcmas A., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 412, Montréal 109, (Québec) 01-02-71 Parent, Benoît, Place Victoria, app.808, Montréal 115, (Québec) 23-08-72 Pearson, Hyman H., 4780, Côte des Neiges Rd., Apartment 19, Montréal 247, (Québec) 06-02-71 Poch, Lewis-Neville, 1, Westmount Square, Suite 346, Westmount 216, (Québec) 14-04-71 Robinson, Wilfrid R., 3410, Benny, #1, Montréal (Québec) 17-01-74 Rogers, Mervyn Allen, 4300, boulevard de Maisonneuve ouest, Appartement 702, 06-02-71 Montréal 215, (Québec) Rosen, Harry, 3545 Côte Ste-Catherine, #400, Montréal (Québec) 03-02-74 Rudick, Gérald-S., 5940, Queen Mary Road, Suite 400, Montréal 248, (Québec) 30-01-71 Saint-Denis, Ronald, 2819, rue Masson.Montréal (Québec) 20-06-74 Samis, Philip L., 1 Place Ville-Marie, Suite 1521, Montreal 113 (Québec) 17-01-74 Shevell, Melvyn, 6000 Côte des Neiges, suite 200.Montréal (Québec) 13-04-74 Sikora, Oskar Paul, Dental Clinic, 1660, Cedar Avenue, Montreal 109, (Québec) 31-01-71 Smaill, Stanton S., 1414 Drummond.suite 1124, Mcntréal 107 (Québec) 26-05-74 Stockwell, William Gordon, 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, 09-03-71 Montreal 109, (Québec) Van Vliet, Jonothan E., 1538, Sherbrooke Street West, Suite 805, Montréal 109, (Québec) 08-03-71 Vinet, Ephrem, 426, boulevard St-Joseph est, Montréal 176, (Québec) 08-02-71 Walford, Wallace Francis, 1414 Drummond Street, Montréal (Québec) 30-05-74 Ward, Doryl B., 1414 Drummond Street, Apt.517, Montreal (Québec) 08-06-74 Weinlander, Gérard H.G., 1650, Cedar Avenue, Montreal 109, (Québec) 08-10-73 Weinstein, Paul R., 5025, Sherbrooke West, #260, Montréal 260, (Québec) 01-12-73 Région de Québec \u2014 Québec Region Boucher, Marc, 1000, chemin Ste-Foy, Suite 302, Québec 6, (Québec) 31-01-71 Crutchfield.G.B.990, des Erables, Québec (Québec) 13-06-74 McGibbon, D.P., 990.des Erables, Québec (Québec) 09-06-74 Simard, Armando, 1179, des Erables, Québec (Québec) 26-05-74 Yeillette, Denis, 2860.Quatrc-Bourgeois, Ste-Foy (Québec) 20-06-74 Région des Cantons de l'Est \u2014 Eastern Townships Region Belleville, Paul, 510, Gait ouest, Sherbrooke (Québec) 31-05-74 Dugal, Paul-Laurent, 459A, Lindsay, Drummondville, (Québec) 08-02-71 Gendron, Georges, 189, Notre-Dame sud, Thetford Mines (Québec) 06-06-74 Gosselin, Viateur, 854, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) 16-05-73 Lessard, Pierre, 189, Notre-Dame sud, Thetford Mines (Québec) 30-05-74 Marcoux, Jean-F., 448 rue King ouest, app.4, Sherbrooke, (Québec) 11-04-71 Obvier, Valmore H., 843, Belvédère sud, Sherbrooke, (Québec) 07-02-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G juillet 1971,, 106< année, n° 27 \u20221929 Professionnels non participants Son-participating professionals Chirurgiens-dentistes Dental Surgeons Date effective de non-participation Effective date of non-participation Région de l'Outaouais \u2014 Outaouais Region l'roulx.Jacques, 214, boulevard Saint-Joseph, Hull, (Québec) Région de Témiscaininguc \u2014 Témiscamingue Region Bellchumcur, Claude, 10.McQuaig est, Rouyn (Québec) Région du Saint-Maurice \u2014 St.Maurice Region Prud'homme, Picrre-P., 1930.3c Avenue.Shawinigan-sud.(Qirboc) Optométristes Optometrists Région de Montréal \u2014 Montreal Region Breton, Antonio, 1530, nie des Cascades, Saint-Hyacinthe, (Québec) Pharmaciens Pharmacists Région de Québec \u2014 Québec Region Auger, Raoul, 1606, Rouville, Ste-Foy, Québec 10, (Québec) Laliberté, Jean, Fortierville, Lotbinière, (Québec) Thibault, Urbain, 9926, Royale, Ste-Anne-de-Beaupré, (Québec) Région de Montréal \u2014 Montreal Region Jacques, Elphège, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Jacques, Paul-Léon, 188 est, rue Principale, Farnham, Missisquoi, (Québec) Moisan, Maurice, 3477, Drummond, App.503, Montréal 107, (Québec) Podlog, Charles, 531.Abercorn, Ville Mont-Royal, Montréal 305, (Québec) Venne, Rosario, St-Hippolyte, Terrebonne, (Québec) Région du Saguenay, Lac St-Jean \u2014 Saguenay, Lake St.John Region Tremblay, Jean-Marie, Case postale 40, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saguenay, (Québec) Région du Nord-Ouest \u2014 North West Region Morin, Léo-Paul, Case postale 570, rue Notre-Dame de Lourdes, Ville-Marie, Témiscamingue, (Québec) Surkis, Max, 68, avenue des Pins, Lebel-sur-Quévillon, Abitibi, (Québec) 57795o 05-05-71 11-04-74 05-05-74 31-12-70 29-06-73 26-10-72 22-09-72 15-09-72 15-09-72 05-01-73 15-03-73 04-04-73 05-10-72 01-10-72 16-11-72 Ministère des Affaires municipales Department of Municipal Affairs Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la Loi sur l'évaluation foncière, j'oidcnne que les limites du territoire du district de révision de Q lébcc du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la ville d'Ames.Lu présente ordonmnee entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 20 juin 1974.Le ministre des affaires municipales.5779 l-o VlCTOK C.GoLDBLOOM.Québec Real Estate Assessment Hoard of Revision Pursuant to section 44 of the Real Estate Assessment Act.I hereby order that the limits of the territorv of the Québec District of the Québec Reel Estate Assessment Bcaid of Revision be modified to include therein the territcy of the Town of Amos.The present order shall come into force on the date of its publication in the Québec Official Gazelle.Québec, June 20, 1974.Victor C.Goldbloom, 57791 .1/inisler of Municipal Affairs. 4930 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.July 6.1974, Vol.106, No.37 Bureau de révision de revaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la Ia>\\ sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Québec du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la corporation du comté de Matane.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 21 juin 1974.Le ministre des affaires municipales.57791-0 VlCTOK C.CiOLDBLOOM.Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Conformément à l'article 44 de la 1/ i sur l'évaluation foncière, j'ordonne que les limites du territoire du district de révision de Montréal du Bureru de révision de l'évaluation foncière du Québec soient modifiées pour y inclure le territoire de la corporation du comté de Shef-ford.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 20 juin 1974.Le minisire des affaires municipales.57791-0 ViCToit C.Goldbloom.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Bauneville Cadastre officiel du canton de Bi'.uneville, division d'enregistrement de Témiscamingue.Avis est par la présente donné que les lots 36C à 36F.37C à 37E.38D à 38F.39E et 39F.40.41.42C et 42D.43C et 431).44C.et 441) du rang VI sont ajoutés et que les lots 35, 36A.3615.37A.37B, 38A, 38B.38C.39A, 39B, 39C, 39D, 40A.40B.41A.41B.42A.4215.43A.4315.44A.44B.45A, 4515.46A, 4615.4715 du rang VI sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 17 mai 1974.l'our le sous-ministre, 37760-o BExolr Gkimaud, a.- LA CITÉ ET DU DIS-l TRICT DE MONTRÉAL, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 266 ouest, rue St-J»cques, à Montréal, demanderesse, versus ROGER PÉLADEAU, résidant au 3377 Monselet, à Montréal-Nord, & al, défendeurs.« Un emplacement ayant front à la trente-huitième avenue, dans le quartier Rosemont, en la Cité de Montréal, composé ainsi qu'il suit: De la partie nord-ouest du lot numéro huit cent trente-deux de la subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-neuf (Ptie N.O.189-832) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation: mesurant vingt-quatre pieds et cinq dixième de pied de largeur (24.5') par une profondeur de quatre-vingt-dix pieds (90') et bornée ainsi qu'il suit: en front, au sud-ouest par la 38ième avenue, en arrière au nord-est par le lot numéro 189-847 étant une ruelle; d'un côté, au sud-est par le résidu dudit lot 189-832 et de l'autre côté, au nord-ouest, par la partie du lot numéro 833 ci-après décrite; De la partie sud-est du lot numéro huit cent trente-trois de la subdivision du lot originaire numéro cent quatre-vingt-neuf (Ptie S.E.1S9-833) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation; mesurant douze pieds et cinq dixième de pied (12.5') de largeur par quatre-vingt-dix pieds (90') de profondeur, mesure anglaise et plus ou moins, bornée ainsi qu'il suit: en front au sud-ouest, par la 38ième avenue; en arrière, au nord-est, par le lot 189-847 étant une ruelle; d'un côté au sud-est par le lot numéro 189-832 ci-haut décrit et de l'autre côté au nord-ouest par le résidu dudit lot 189-833.(b) Original lot number thirty-nine of Range Nine (39, Rge IX) (western side of the river) on said official plan and in said book of reference.(c) Original lot number thirty-eight of Range Seven (38, Rge VII) (western side of the river) on said official plan and in said book of reference.Bounded on the west by lot 29, Range VII, on the north by lot 39, on the south by lot 37, on the east and on the northeast by Lake Ares and lot 39-156.Less and to withdraw, however, those parts which has been the subject of an official subdivision duly filed at the Registry Office and also those parts already sold by registered contracts.\" To be sold at the Montcalm Registration Division Office, in Ste.Julienne, District of Joliette, on TUESDAY, the TWENTIETH day of AUGUST, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Christian Roy, Sheriff's Office, Sheriff.Joliette, June 25, 1974.57794 MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal I \\/f ONTREAL CITY AND DIS-No.05-016799-73X J-Vl TRICT SAVINGS BANK, V.a corporation legally incorporated having its principal place of business at 266 St.James Street West, in Montreal, plaintiff, versus ROGER PÉLADEAU, residing at 3377 Monselet, in Montreal-North, & al, defendants.\"An emplacement fronting on Thirty-eighth Avenue, in Rosemont Ward, in the City of Montreal, comprising the following: The northwest part of lot number eight hundred thirty-two of the subdivision of original lot number one hundred eighty-nine (N.W.Pt.189-832) on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village cf Côte-de-la-Visitation; measuring twenty-four and five tenths feet in width (24.5') by a depth of ninety feet (90') and bounded as follows: in front, on the southwest by 38th Avenue, in the rear on the northeast by let number 189-847, which is a lane; on one side, on the southeast by the remainder of said lot 189-832 and on the other side, on the northwest, by that part of lot number 833 hereinafter described; The southeast part of lot number eight hundred thirty-three of the subdivision of original lot number one hundred eighty-nine (S.E.Pt.189-833) on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte-de-la-Visitation; measuring twelve and five tenths feet (12.5') in width by ninety feet (90') in depth, English measure and more or less, bounded as follows: in front, in the southwest, by 38th Avenue; in the rear, on the northeast, by lot 189-847 being a lane; on one side on the southeast by lot number 189-832 hereinabove described and on the other side on the northwest by the remainder of said lot 189-833. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, G juillet 1974, 10G' année, n' 27 4951 Avec la bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 6605, de la 38ième avenue à Rosemont, et dont les deux murs latéraux sont mitoyens.Sujet à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, attachées audit immeuble, et notamment avec et sujet à une servitude mutuelle et réciproque de droit de vue telle qu*établie aux termes d'un acte enregistré sous le numéro 1138664.Les mesures ci-dessus mentionnées sont à la mesure anglaise et plus ou moins.» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le SEPTIÈME j our du mois d'AOÛT 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 26 juin, 1974.57778-o With the building erected thereon, bearing civic number 6605, 38th Avenue in Rcsemont, and whose two side walls are common.Subject to all active and passive, apparent or non apparent servitudes attaching to said immoveable, and namely with and subject to a mutual and reciprocal servitude of view as established under the terms of a deed registered under number 1138664.The measurements hereinabove mentioned as in English measure and more or less.» To be sold at the Sheriff's Office, in the City or Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56.on the SEVENTH day of AUGUST.1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, June 26, 1974.57778 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'ÉPARGNE DE No 05-015929-73X J-' LA CITÉ ET DU DIS-vTRICT DE MONTRÉAL, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 266 ouest, rue Saint-Jacques, à Montréal, demanderesse, versus GÉRARD DESJAR-DINS, résidant au 1350, Chemin Ste-Claire, Rivière Beaudette, comté de Soulanges, district judiciaire de Montréal, et al, défendeurs et LE REGISTRATEUR de Laval, mis en cause.« Un certain emplacement ayant front sur le numéro 330, rue Couperin en la ville de Laval, connu et désigné comme étant les numéros de subdivision trois cent quinze et trois cent seize du lot originaire numéro deux cent cinquante-deux (252-315 et 316) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Martin, mesurant quatre-vingt-cinq pieds de largeur sur cent pieds de profondeur, couvrant une superficie totale de huit mille cinq cents pieds carrés (8,500 pi.ca.), le tout en mesure anglaise et plus ou moins.Avec la bâtisse y érigée portant le numéro civique 330, rue Couperin, Laval, dont tous les murs sont indépendants.Sous réserve des servitudes en faveur de la Québec Natural Gaz Corp., de l'Hydro-Québec et de Bell Canada Ltd., telles qu'elles ont été établies par des actes de servitudes enregistrés à Laval sous les numéros 268671 et 261768 et une servitude de passage enregistrée à Laval sous le numéro 281005.Telle que la propriété se trouve présentement, avec tous ses droits, membres et circonstances, sans aucune exception ni réserve.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, au 155, boulevard Je-Me-Souviens, à Laval, (Québec), le SIXIÈME jour d'AOÛT 1974, à DIX heures de la matinée.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint, Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 26 juin 1974.57787 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal l T'HE MONTREAL CITY AND No.05-015929-73X A DISTRICT SAVINGS ' BANK, a corporation legally incorporated, having its principal place of business at 266 St.James Street West, in Montreal, plaintiff, versus GÉRARD DES.IARDINS, residing at 1350 Ste.Claire Road, Rivière Beaudette, County of Soulanges, Judicial District of Montreal, et al, defendants and THE REFISTRAR of Laval, mis en cause.\"That certain emplacement fronting on 330 Couperin Street in the City of Laval, known and designated as subdivision numbers three hundred and fifteen and three hundred and sixteen of original lot number two hundred and fifty-two (252-315 and 316) on the official plan and book of reference of the Parish of St.Martin, measuring eighty-five feet in width by one hundred feet in depth containing a total superficial area of eight thousand five hundred square feet (8.500 sq.ft.), the whole English measure and more or less.With the building thereon erected bearing civic number 330 Couperin Street of Laval all the walls whereof are indépendant.Subject to servitudes in favour of Québec Natural Gas Corp., Hydro-Québec and Bell Canada Ltd.as established in deeds of servitude registered at Laval under Nos.268671 and 261768 and a servitude of passage registered at Laval under number 281005.As the said property now subsists, with all its rights, members and appurtenances, without exception or reserve.\" To be sold at the County of Laval Registry Office, 155 Je-Me-Souviens Boulevard, in Laval, P.Q., on the SIXTH day of AUGUST 1974.at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, June 26th, 1974.57787-0 4952 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1904, Vol.106, No.37 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal [ ftERTIL INTERNATIONAL No 05-O00165-74X ^ LIMITED, demanderesse, \u2022 La resubdivision soixante-sept de la subdivision trois du lot originaire deux cent soixante-dix-neuf (279-3-67) du cadastre susdit.» « La resubdivision soixante-six de la subdivision trois du lot originaire deux cent soixante-dix-neuf (279-3-66) du cadastre susdit.» « La redivision un de la resubdivision seize de la subdivision trois du lot originaire deux cent soixante-dix-neuf (279-3-16-1) du cadastre susdit.» Avec la maison multi-familiale de 28 logements dessus construite, portant le numéro civique 475, 51e rue ouest, Charlesbourg, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec P.Q.le VINGTIÈME jour d'AOUT 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif.J.Roland Renault.Québec, le 28 juin 1974.57786-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit :/ pENERAL TRUST OF CA-Superior Court, J NADA, a corporation legally No.16-499.J incorporated having a place of ' business at 1091 St.Louis Road, Québec 6, vs CLAUDE GAGNON, residing at 6676 Place des Phlox, Orsainville, and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mit en cause.\"Redivision two of resubdivision sixty-nine of subdivision three of original lot two hundred seventy-nine (279-3-69-2) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division.\" \"Resubdivision sixty-eight of subdivision three of original lot two hundred seventy-nine (279-3-68) on the aforesaid cadastre.\" \"Resubdivision sixty-seven of subdivision three of original lot two hundred seventy-nine (279-3-67) on the aforesaid cadastre.\" \"Resubdivision sixty-six of subdivision three of original lot two hundred seventy-nine (279-3-66) on the aforesaid cadastre.\" \"Redivision one of resubdivision sixteen of the subdivision three of original lot two hundred seventy-nine (279-3-16-1) on the aforesaid cadastre.\" With the multi-dwelling house containing 28 dwellings, bearing civic number 475-51st Street West, Charlesbourg, appurtenances and dependencies.To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, Québec, on the TWENTLETH day of AUGUST, 1974 at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 28, 1974.57786 4956 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: t pLAUDE MIVILLE INC., Cour Provinciale, ) corporation légalement No 002-02-000403-73.1 constituée, ayant une place (.d'affaires au 4820, 5e Avenue est, Charlesbourg, P.Q.,versus PIED CARRE INC., corporation légalement constituée, ayant une place d'affaires au 1815, boulevard Masson, Les Saules, district de Québec.« Le lot 52-11-1 partie du cadastre officiel de la paroisse de L'Ancienne-Lorette ».* Le lot 52-15-2 partie du cadastre officiel de la paroisse de L'Ancienne-Lorette avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances.» Pour être vendus au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, P.Q.le VINGTIÈME jour du mois d'AOUT 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Raymond Hains.Québec, le 28 juin 1974.57784-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / /~iLAUDE MIVILLE INC., Provincial Court.) >^ a corporation legally in-No.002-02-000403-73.1 corporated, having a place of \\ business at 4820 - 5th Avenue East, Charlesbourg, P.Q.versus PIED CARRE INC., a corporation legally incorporated, having a place of business at 1815 Masson Boulevard, Les Saules, District of Québec.\"Lot 52-11-1 part of the official cadastre for the Parish of L'Ancienne-Lorette.\" \"Lot 52-15-2 part of the official cadastre for the Parish of L'Ancienne-Lorette, with the building erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, P.Q.on the TWENTHLETH day of AUGUST, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Raymond Hains, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 28, 1974.57784 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: [TA CITÉ DE LAUZON, vs Cour Provinciale, ) *\u2022> ARMAND PARÉ, domi-No 200-02-000502-742) cilié à 229 Eleen St.Amesbury, { Mass.États-Unis, et LES HERITIERS DE FEUE DAME MARIE ANNE PARÉ épouse de Léo Larochelle, domiciliée à 75, S.Kimball St.Haverhill, Mass.U.S.A., JOSEPH PARÉ, domicilié à 11 Lincol comté Amesbury, Mass.U.S.A., LES HÉRITIERS DE FEU ALEXANDRE PARÉ, domicilié à 186 Reed St.Manchester New-Hampshire U.S.A., DAME SIMONE PARÉ NICHOL, domiciliée à P.O.Box 119, Amesbury, Mass.États-Unis, DAME BLANCHE BEAULIEU vve de Joseph Edouard Drapeau, domiciliée à 52 St-Dominique, Québec, DAME VVE LUCIENNE PARÉ GUILLEMETTE, pensionnaire chez les Soeurs Franciscaines Missionnaires, 383 Grande-Allée, Québec, LES HÉRITIERS DE FEU ANTOINETTE PARÉ, épouse de Arthur Dallaire, de lieux inconnus, LES HÉRITIERS DE FEUE GABRIELLE PARÉ, lieux inconnus, ALMAN-ZOR PARÉ, domicilié à 14 Stever Court, Amesbury, Mass.États-Unis, MAURICE PARÉ, domicilié à 3 Garfield St.Amesbury, Mass.États-Unis, DAME MARGUERITE PARÉ, épouse de Arthur Poulin, domiciliée à 100, Hillside Ave., Amesbury, Mass.États-Unis.Lot 794-1, ville de Lauzon.Quartier Fafard, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Lévis, 113 rue St-Georges ouest, Lévis, comté Lévis, le VINGT-DEUXIÈME jour d'AOÛT 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, ce 28 juin 1974.57781-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: t '\"THE CITY OF LAUZON, Provincial Court, ) *¦ vs ARMAND PARÉ, No.200-02-000502-7421 domiciled at 229 Eleen Street, v.Amesbury, Mass, U.S.A., and THE HEIRS OF THE LATE MRS.MARTE ANNE PARÉ, wife of Léo Larochelle, domiciled at 75 South Kimball Street, Haverhill.Mass, U.S.A., JOSEPH PARÉ, domiciled at 11 Lincol, County of Amesbury, Mass., U.S.A., THE HEIRS OF THE LATE ALEXANDRE PARÉ, domiciled at 186 Reed Street, Manchester, New Hampshire, U.S.A., MRS.SIMONE PARÉ NICHOL, whose postal address is Post Office BOX 119, Amesbury, Mass., U.S.A., MRS.BLANCHE BEAULIEU, widow of Joseph Edouard Drapeau, domiciled at 52 St.Dominique, Québec, MRS.LUCIENNE PARÉ GUILLEMETTE, widow, residing at Les Soeurs Franciscaines Missionnaires, 383 Grande-Allée.Québec.THE HEIRS OF THE LATE ANTOINETTE PARÉ, wife or Arthur Dallaire, of unknown address.THE HEIRS OF THE LATE GABRIELLE PARÉ, of unknown address, ALMANZOR PARÉ, domiciled at 14 Stever Court, Amesbury, Mass., U.S.A., MAURICE PARÉ, domiciled at 3 Garfield Street, Amesbury, Mass., U.S.A., MRS.MARGUERITE PARÉ, wife of Arthur Poulin, domiciled at 100 Hillside Avenue, Amesbury, Mass., U.S.A.Lot 794-1, City of Lauzon, Fafard Ward, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold at the Levis Registry Office, 113 St.Georges Street West, Levis, County of Levis, on the TWENTY-SECOND day of AUGUST, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 28, 1974.67781 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1973, 106' année, n\" 87 4957 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:/T M.DESSUREAULT (1971) Cour Supérieure, ) J \u2022 INC., corporation légalement No 11-748 ) constituée ayant son siège social en ' la cité de Québec, district de Québec vs, RENÉ LEFAIVRE, ALBERT VERROEULST, YVON DESWAIDE, ès-qualité de syndics à la faillite de JEAN ROY INC., faisant affaires à 56, rue St-Pierre, Québec, district de Québec et LE REGISTRATEUR pour la division d'enregistrement de Château-Richer, mis en cause.« La subdivision six du lot originaire deux cent quarante (240-6) du cadastre officiel de L'Ange-Gardien, la subdivision huit du lot originaire deux cent trente-huit (238-8) du cadastre officiel de L'Ange-Gardien.> Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Montmorency, 8032 Royale, Château-Richer, comté de Montmorency, le SEIZIÈME jour d'AOÛT 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 28 juin 1974.57782-o Fieri Facias de Terris Quebec, to wit : ( T M.DESSUREAULT (1971) Superior Court, ) J \u2022 INC., a corporation legally in-No.11-748.\\ corporated, having its head office in V the City of Québec, District of Québec, vs RENÉ LEFAIVRE, ALBERT VERROEULST, YVON DESWAIDE, in their capacity as trustees in the bankruptcy of JEAN ROY INC., carrying on business at 56 St.Pierre Street, Québec, District of Québec, and THE REGISTRAR for the Château-Richer Registration Division, mis en cause.« Subdivision six of original lot two hundred forty (240-6) on the official cadastre for L'Ange-Gardien, subdivision eight of original lot two hundred thirty-eight (238-8) on the official cadastre for L'Ange-Gardien.\" To be sold at the Montmorency Registry Office, 8032 Royale, Château-Richer, County of Montmorency, on the SIXTEENTH day of AUGUST, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 28, 1974.57782 Fieri Facias de Terris Quebec, à savoir: ( \"V^CDONALD, CURRIE &CIE.Cour Supérieure, ) -\"1 comptables agréés, faisant No 12-603.1 affaires ensemble au 2 Place Québec, \\ cité et district de Québec contre GÉRARD PROULX, domicilié au 3333 rue B rouage, Ste-Foy, district de Québec et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Le lot numéro trois cent quatre-vingt-un (381) des subdivisions du lot originaire numéro quatre cent trois (403-381) du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Foy, maintenant ville de Ste-Foy, division d'enregistrement de Québec; avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, P.Q.le VINGTIÈME jour d'AOÛT 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.Roland Renault.Québec, le 28 juin 1974.57783-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit: / \"VifCDONALD, CURRIE & CIE, Superior Court, J LVl chartered accountants, car-No.12-603.J rying on business together at 2 Pla-v.ce Québec, in the City and District of Québec, versus GÉRARD PROULX, domiciled at 3333 Brouage Street, Ste.Foy, District of Québec and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause.\"Lot number three hundred eighty-one (381) of the subdivisions of original lot number four hundred three (403-381) on the official cadastre for the Parish of Ste.Foy, now the City of Ste.Foy, Québec Registration Division ; with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, Québec, on the TWENTIETH day of AUGUST, 1974 at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, June 28, 1974.57783 I'.l.-s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6.197J,, Vol.106, No.27 INDEX No 27 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ARRÊTÉS EN CONSEIL ORDERS IN COUNCIL 2268-74 2268-74 2269-74 2269-74 Laurentian, c.s-s.b.(Ancien nom: Municipalité scolaire d'Argenteuil).4934 Laurentian, c.s.-s.b.(Former name: Argenteuil School Municipality).4934 Blainville-Deux-Montagnes, c.s.r.(Ancien nom: Commission scolaire régionale Deux-Montagnes) 4934 Blainville-Deux-Montagnes, r.s.b.(Former name: Deux-Montagnes Regional School Board).4934 AVIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Barnes (James T.) Mortgage Loan Company (Loan and Investment Societies Act).4939 Montréal, ville-city (Rachat d'obligations-Redemption of bonds).4938 Sillery, cité-city (Requête-Pétition).4939 Société de prêts hypothécaires James T.Barnes (La) (Loi des sociétés de prêts et placements).4939 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Bernier, Marie Georgette.4921 Carrier, Patricia Ann.4922 Côté, Joseph Edmond Vianney.4922 Holland, Mary Jo.4922 Lemian, Léon Vahan.4922 Leroux, Roland.4922 Ransen, Irving Rocke.4922 Rayson, Allan.4923 Vasilach, Serge.4923 Williams, Helen.4923 Demandes: Applications: Anantharamaiah, Jambur Venkatasubbaiah.4921 Brougham, Michel.4920 Chrystal, Gary Arthur.4920 Demers, Gilles.4920 Garfinkle, Steven Michael.4920 Grenon, Serge.4920 Hussel, Joseph Jean-Paul.4921 Jolivet, Joseph, ïmu'is, Orastide.4921 Perron, Joseph Robert Richard.4921 Zappavigna, Nicola.4920 COMMISSION Commission des transports du Québec COMMISSION Québec Transport Commission Avis de la Commission « proprio motu ».4893 Avis de décisions rendues.4901 Avis de désistement.4900 Avis d'introduction de requêtes.4896 Notice \"proprio motu\" by the Commission 4893 Notice of decisions rendered.4901 Notice of withdrawal.4900 Notice of submission of applications.4896 COMPAGNIES \u2014 LOI DES Abandon de charte Alpha Fur (Québec) Ltd.COMPANIES ACT Surrender of Charter .4873 Association des locataires de Beloeil inc.(L') 4873 B.& W.Construction Ltd.4873 Bel Canto inc.(Les).4873 Biais & Paré ltée.4873 Boucher (J.Edouard), ltée.4873 Boutique André Jarest ltée (La).4873 Compagnie de l'Hôtel Windsor de Hull (La) 4873 Confection Christiane inc.4873 Hull Windsor Hotel Company (The).4873 Indevco Québec Limited.4873 Mado Development Ltd.4873 Nova Metal Inc.4873 Pétroles Azurs inc.(Les).4873 Rénovations résidentielles Western inc.4873 Sport-Club de Québec, inc.(Le).4873 Sport-Club of Québec, Inc.(The).4873 Virball Electric Co.Ltd.4873 Western Home Renovations Inc.4873 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106- année, n\" 27 4959 Administrateurs Directors (Article 84) (Section 84) Belmont Realties Limited.4880 Bijouterie Lucien Larose inc.4880 CJRP Radio Provinciale limitée.4880 Cometal inc.4880 Du-Var Laboratory Incorporated.4880 Fallinger Corporation.4880 Gerari Inc.4880 Groupe Prenor ltée.4881 Hôtel Paul Baillargeon (Jonquière) inc.4880 Hôtel Royal Lac-Mégantic inc.4880 Immeubles C.J.L.R.inc.(Les).4880 Jurihome Inc.4880 Laboratoire Du-Var incorporée.4880 Lussier (Gabriel) Ltd.4881 Lussier (Gabriel) ltée.4881 Marché L.D.J.A.inc.4881 Minakakis Travel Service Inc.4881 Modella Inc.4881 Modem Technical Services (Québec Division) Ltd.4881 Montemurro (J.) Inc.4881 Pierce Investment Corp.4881 Post-Productions Inc.4881 Potterton Productions Inc.4881 Prenor Group Ltd.4881 Régional ltée (Le).4881 Restaurants B & R incorporée (Les).4881 Restaurants Renaissance inc.4881 Services Techniques Modernes (Division de Québec) ltée.4881 Société de mécanique de construction somec inc.4881 Somerville House Corporation (The).4881 Superseal Corporation.4881 Therapex Corporation.4881 Thurso Pulp and Paper Company.4881 Trebmalts Limited.4881 Trebmalts Limited.4881 Changement de nom Change of name Alruga Inc.4890 Baronet Printing Ltd.4890 Berol Ltd.4890 Berolltée.4890 Buanderie et Location d'uniformes Cité ltée.4890 City Laundry and Uniform Rental Ltd.4890 Commerce du plastique & du caoutchouc inc.4890 De Cotret (Marcel R.) inc.4890 Discothèque Fumée Liquide inc.4890 Garage T.O.S.ltée.4890 Huiles Penco-Olympic inc.(Les).4890 Imprimerie Baronet ltée.4890 Liquid Smoke Discotheque Inc.4890 Modes Philip B.inc.4890 Philip B.Fashions Inc.4890 Plastic & Rubber Trading Co.Inc.4890 Publications du Messager inc.(Les).4890 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Ajusteurs de l'Est ltée.4937 Brassard (J.A.) limitée.4936 Broslyn Marking Machines Inc.4936 Erny's Little Dept.Store Ltd.4936 Eastern Adjusters Ltd.4937 Machines de marquage Broslyn inc.4936 Matha Lake Development Ltd.4937 Pesner (A.) & Co.Inc.4937 Shop Eze (1965) Inc.4936 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) Aberdeen Clothing Co.4886 Acme Buffing & Plating Co.Ltd.4887 Allard (Alphonse) inc.4886 Alliance Trans-Kebec Alliance ltée.4886 Ascenseurs Viau inc.4886 Association du mouvement scout Bon-Pasteur (Laval) inc.(L').4886 Bonaventure Enterprises Limited.4886 C.T.D.Development Inc.4887 Champion Thread (1973) Ltd.4886 Charbonneau (Elie) & fils inc.4886 Charbonneau (Roger) ltée.4886 Cie de polissage et placage Acme ltée (La).4887 Cie de tabac Terrebonne limitée.4887 Club Optimiste de Rouyn-Noranda inc.4887 Club Victoire.4887 Cohen (Peter) Realties Inc.4887 Colamac Inc.4887 Comm.Electric Co.Inc.4887 Constructions Albert Sanscartier inc.(Les)., .4887 Dawco Realties Ltd.4887 Dejalexltée.4887 Développement Conseil inc.4887 Développements C.T.D.inc.(Les).4887 Directe Publications Inc.4887 Dumais (Jean-Paul) inc.4887 Durotalon Corporation.4887 Emery's Exclusive Furs Inc.4887 Entraide missionnaire (L').4887 Entreprises Bonaventures limitée (Les).4886 Entreprises du Saguenay inc.4887 Fédération Provinciale de judo et disciplines assimilées.4887 Fil Champion (1973) ltée (Le).4886 Flam Textiles Co.Ltd.4887 Forterest Inc.4887 Freder (M.) Textiles inc.4887 Giroux, Phaneuf et associés inc.4888 Green Park Investment Corp.4888 Hasen Corporation (The).4888 Hôtel Paul Baillageon (Jonquière) inc.4888 Immeubles Bertford inc.(Les).4888 Interstyle Group Ltd.4888 Lafarge béton ltée.4888 Lafarge Concrete Ltd.4888 Lavoie (Eugène) inc.4888 4960 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.27 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) (suite (continued) Lilklar Holdings Ltd.4888 Lousel Inc.4888 Marchessault (A.) limitée.4888 Montbec Company Limited.4888 Northern Packers Ltd.4888 Paquet (Michel) inc.4888 Paysan de Chambly inc.(Le).4888 St-Yvcs (Donat) inc.4888 Samuels Plumbing & Heating Inc.4888 Scene Holdings Inc.4888 Semco Investment Corp.4888 Service régional des loisirs de Montréal.4888 Sidmor Children's Wear Ltd.4888 Société de mécanique de construction Somec inc.4888 Style Queen Dress Inc.4888 Summit Corporation.4889 Sylvain (Edmond) limitée.4889 Taverne Yvan ltée.4889 Télécâble de la Rive-Sud inc.4889 Tropicarium Inc.4889 Viau Elevators Inc.4886 Lettres patentes Letters Patent (1\" partie) (Part I) A.A.S.Investments Ltd.4878 A.C.M.Construction Inc 4^75 A.C.M.Homes Inc.4877 Acceleration Personnel Services-Human Resources Inc.4874 Accélération personnel-services ressources humaines inc.4874 Aérocoustic inc.4874 Airline Seventeen Fifty-One Machinist Welfare Association Inc.4874 Altinorlnc.4874 Ambulance Deux Mille inc.4874 Association de bienfaisance des machinistes aériens Dix-Sept Cinquante et Un inc.(L\").4874 Assurances Martel inc.4874 Atelier de transformation de bois & crétagc de Honneur inc.(L').4874 Atelier électronique Des Rivières inc.4874 Ateliers d'ébénisterie d'Alma inc.(Les).4874 Automobile M.Roy inc.4874 Aviation Lima inc.4874 Beauceville Truck Service Inc.4879 Bélanger (Henri-Paul) Realties Inc.4877 Berkshire Holding Inc.4874 Bijouterie Baie Comeau inc.4874 Bijouterie Camille & André inc.4874 Bison Driver Services Inc.4879 Blanchette (F.& J.) ltée.4874 Bois Delta ltée.4874 Boisvert (Michel) inc.4874 Boucherville Trailers Ltd.4879 Boutique Cotillon inc.4874 Boutique de Bernières inc.4875 C.B.Design Ltd.4875 C.I.Asphalt & Landscape Co.Inc.4875 C.M.L.Printing Plates Inc.4878 Carrier & Boulay inc.4875 Centre Laval (1974) inc.4875 Chevrons R.B.R.inc.(Les).4875 Chomedey Springs Service (1974) Inc.4879 Club de cricket Verdun, Montréal inc.4880 Compagnie d'asphalte & de terrassement CI.inc.(La).4875 Compagnie d'expédition Searam ltée (La).4875 Construction Cum ltée.4875 Construction Deplour inc.4875 Constructions A.C.M.inc.(Les).4875 Constructions Mario & Frères inc.(Les).4875 Corporation d'aménagement Normont ltée.4878 Corporation d'aménagement Sonva ltée.4879 Corporation Davi ltée.4875 Côte, haute coiffure inc.(La).4875 Couvreurs F.M.inc.4875 Crémazie Auto Repair (1974) Inc.4875 Cum Construction Ltd.4875 Dalcourt and Roussel Enterprises Inc.4876 Danisabel inc.4875 Dansbec Inc.4875 Davi Corporation Ltd.4875 Davis & Lemish Inc.4875 Delta Lumber Ltd.4874 Design C.B.ltée.4875 Devoe (Martin J.) & fils inc.4875 Devoe (Martin J.) & Son Inc.4875 Distributeurs Norton inc.(Les).4878 Distribution domestique Arlef inc.4875 Distribution Vanier ltée.4875 Donora Realties Ltd.4877 Emesar Ltd.4876 Emesarltée.4876 Entreprises A.R.D.Rodrigue inc.4876 Entreprises Boily & fils inc.(Les).4876 Entreprises Dalcourt et Roussel inc.(Les).4876 Entreprises électriques Bedford inc.(Les).4876 Entreprises Felder inc.4876 EntreprisesG.M.B.D.ltée (Les).4876 Entreprises J.G.F.ltée (Les).4876 Entreprises J.M.Thibault inc.(Les).4876 Entreprises J.P.B.R.inc.(Les).4876 Entreprises Joroc inc.4876 Entreprises Jovan ltée.4877 Entreprises Noèl Briand inc.(Les).4876 Entreprises Octave inc.(Les).4876 Entreprises Pabeva inc.(Les).4876 Entreprises Pylo inc.4876 Entreprises Winco inc.(Les).4880 Erection Breton ltée.4876 Europex Investments Ltd.4876 Excavations M.G.Naud inc.(Les).4876 F.M.Roofing Inc.4875 Ferme Les Loisirs Plein-Air inc.(Les).4876 Ferme Tracel inc.(La).4876 Fermes de cailles du Québec inc.(Les).4876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106- année.n° 27 4961 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part /) (suite) (continued) Fibres Peralu inc.(Les).4876 Fruits de mer Lagabeau inc.(Les).4877 Garage Mario Larose ltée.4877 Germain (A.) et associés inc.4877 Gerry's Plumbing, Heating, Ventilation Ltd 4878 Gestion A.L.G.inc.4877 Gestion Naspor inc.4877 Gestin Inc.4877 Habitations A.C.M.inc.(Les).4877 Habitations Rayni inc.4877 Hôtel motel Le Mas inc.4877 Houle (Bernard) & fils inc.4877 Ideal Auto Parts Terrebonne Inc.4878 Immeubles Dalquier inc.(Les).4877 Immeubles Donora ltée.4877 Immeubles Henri Paul Bélanger inc.4877 Immeubles Lockport ltée.4877 Immeubles Printaniers inc.(Les).4877 Industries Automobiles Steed (Est) limitée (Les).;.4879 Industries Ben Rioux ltée.4877 Industries Mingan inc.(Les).4878 Installations électriques R.B.inc.(Les).4877 Investissements Europex ltée (Les).4876 Jacbouroy inc.4877 Jovan Enterprises Ltd.4877 Kitchener Holdings Québec Limited.4877 Lamarre (B.) & associés ltée.4877 Launel Inc.4877 Lebeau (Gilles ) inc.4877 Lima Aviation Inc.4874 Location l'Oiseau Jaune du Québec ltée.4880 Lockport Realties Ltd.4877 Magasin de vêtement en gros de la Rive Sud inc.4879 Manoir Côte St-Paul inc.(Le).4878 Mingan Industries Inc.4878 Motel Le Bastion (1974) inc.4878 N.G.B.Transport Inc.4879 Naud (M.G.) Excavation Inc.4876 Normont Development Corporation Ltd.4878 Norton Distributors Inc.4878 Pâtisserie Des Monts inc.4878 Pavage Chabot inc.4878 Pépinière André Masson inc.4878 Photo S.R.T.inc.4878 Pièces d'automobile Idéal, Terrebonne inc.4878 Piermaxi Inc.4878 Pinard & Pinard (1974) ltée.4878 Placements A.A.S.ltée (Les).4878 Placements Berkshire inc.(Les).4874 Placements Dalvin inc.4878 Placements Kitchener Québec limitée (Les) 4877 Placements Revik inc.4878 Planigesco Inc.4878 Plaques d'imprimerie C.M.L.inc.4878 Plomberie, chauffage, ventilation Gerry ltée.4878 Plurigestinc.4878 Popular Produce & Poultry Inc.4878 Porcherie Maumifer inc (La).4878 Produits agricoles & avicoles populaires inc.4878 Publicité Lanaudière inc.4878 Québec Quail Farms Inc.4876 Remorques Boucherville ltée.4879 Réparation automobile Crémazie (1974) inc.4875 Restaurant La Redoute, (1974) inc.4879 Rodrigue (A.R.D.) Enterprises Inc.4876 Rôtisserie Petit Père inc.4879 S.D.Combustion Specialists Inc.4879 S.R.T.Photo Inc.4878 Salon Conrad inc.4879 Scieries B & W inc.(Les).4879 Searam Dispatchers Co.Ltd.4875 Service de radio Victor inc.4879 Service de ressorts Chomedey (1974) inc.4879 Service du camion Beauceville inc.4879 Services de chauffeurs Bison inc.4879 Shugar (Len) and Associates Ltd.4879 Shugar (Len) et associés ltée.4879 Signalex Inc.4879 Sogex Inc.4879 Sonva Development Corporation Ltd.4879 South Shore Factory Outlet Inc.4979 Spécialistes en combustion S.D.inc.4879 Steed Automotive Industries (Eastern) Limited 4879 Stucage Camden Inc.4879 Tapis M.& M.inc.(Les).4879 Thibault (J.M.) Enterprises Inc.4876 Thibodeau (Léonce) & fils ltée.4879 Transport N.G.B.inc.4879 Uniformes et robes l'.rika inc.4880 Vanier Distribution Ltd.4875 Varna ltée.4880 Verdun Cricket Club, Montreal Inc.4880 Victor Radio Service Inc.4879 Winco Enterprises Inc.4880 Yellow Bird Rentals of Québec Ltd.4880 Lettres patentes Letters Patent (3» partie) (Part III) Cercle d'amitié de l'Age d'Or de Drummond- ville Sud.4882 Cercle de Bridge Rosemont ltée.4882 Club de rallye auto Yamaska (C.R.A.Y.).4882 Club social des employés du Centre Cardinal Villeneuve inc.4882 Corporation culturelle, artistique et sociale d'Alma.4882 Corps musical Les Duchesses de Charlemagne 4882 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Association des auxiliaires familiales diplômées de la province de Québec.4889 Automobiles du Roi inc.4889 Britton Electric Co.Ltd.4889 Certified Homemaker Association of Québec.4889 4962 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.37 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent (suite) (continued) Cie Electrique Britton ltée (La).4889 Du Roi Automobiles inc.4889 Clément (Robert) inc.4889 Fondation Richelieu Québec.4889 Grégoire-Lumberland (Wilfrid) Inc.4889 Kwikasair Ltd.4889 Produits Comtois ltée (Les).4889 Quincaillerie Baie-Comeau inc.4890 Société nationale des québécois de la Côte-Nord (SSJB) inc.4890 Siège social Head office (Article 84) (Section 84) Action Vehicle Corporation.4882 Agence G.B.inc.4882 Air Distribution Equipment Inc.4884 Albert Preventive Maintenance Inc.4882 Association du Lac Vert inc.4882 Au Jardinet inc.4882 Barber (C.) Cartage Limited.4882 Boulangeries Unies inc.4882 Bovet inc.4883 Brasserie des Remparts inc.4883 Canada Packaging Ltd.4883 Canadian Tiffany Ltd.4886 Chàteauneuf Boisé inc.(Le).4883 Cheminées Harvey inc.4883 Cholar Inc.4883 Commercial Litho Plate Graining (1970) Ltd.4883 Compagnie Granite Eternité limitée (La).4883 Compumatch Inc.4883 Concrete Investment Inc.4883 Confection Idéale inc.4883 Construction Contrôle inc.4883 Coranit Inc.4883 D.D.Transport ltée.4883 Dallaire Industries Ltd.4884 Deauville Stationers Inc.4885 Decor-Metal Ltd.4883 Déménagements St-Laurent inc.4883 Dernière Heure ltée.4883 Distributeurs Delorimier (1971) inc.4883 Distributions du Nord-Ouest du Québec inc.(Les).4883 Entreprises Capricone limitée (Les).4883 Entreprises Lerch ltée (Les).4884 Entreprises Paré inc.(Les).4883 Equipement de distribution d'air inc.4884 Eternité Granite Company Limited (The)- 4883 Etrefal Inc.4884 Forget (Conrad) inc.4884 Gerem Inc.4884 Gesbec Inc.4884 Gestion La Savane inc.4884 Gestion Opéra limitée.4885 Grand Lodge of Québec of the Antediluvian Order of Buffaloes Inc.(The).4884 Green Lake Association Inc.4882 Hôtel Donnacona ltée.4884 Hôtel St-Lazare inc.4884 Industries Dallaire ltée (Les).4884 Jacobsen (Tom) Inc.4884 Lajoie (Jean-Marc) ltée.4884 Lamy (François) & associés inc.4884 Laporte Construction Inc.4884 Larue (D.), limitée.4884 Lerch Enterprises Ltd.4884 Louvon Construction Inc.4884 Lucerne Electric Ltd.4884 Lucerne Electrique ltée.4884 Marquis (Michel) inc.4884 Matte (J.D.) inc.4884 Montpetit (Ludovic) inc.4884 Moulins à scie Sarrazin inc.(Les).4885 Moulures Progressives inc.4885 Nash Equipment Corp.4885 Nat Tepper Inc.4886 Opera Holding Limited.-\u2022 \u2022 4885 Opérations forestières Barrette & Saucier ltée (Les).4885 Paperiers Deauville inc.4885 Penguin Ski Club (The).4885 Petit Journal ltée.4885 Photo Journal ltée.4885 Placements Tema inc.(Les).4885 Plamondon automobiles incorporé.4885 Plani-Vert inc.4885 Progress Wire Works Inc.4885 Progressive Moulds Inc.4885 Rampart Brewery Inc.4883 Raymond (R.) & associés ltée.4885 Restaurants Les Grands Vaisseaux inc.(Les) 4885 Robec Construction Inc.4885 St-Louis Transport Inc.4885 Sarrazin Saw-Mills Inc.4885 Serana Inc.4885 Service de distribution Richelieu inc.(Le).4885 Sirois inc.4885 Société Apicole du Val Fleuri inc.(La).4886 So Ge Hab incorporée.4885 Sun Valley Nursery Ltd.4886 Tiffany Canadien ltée.4886 Vincent & Co.Inc.4886 CURATELLE PUBLIC PUBLIQUE CURATORSHIP Avis de qualité: Notice of capacity: Brabant.Éva.4935 Gauthier.Patrice.4935 Lajoie, Antonio.4935 Nackle, John Nassif.4935 DEMANDES À APPLICATIONS LA LEGISLATURE TO LEGISLATURE Beaucage ltée.4924 Hillmack Services Ltd.4924 Hull, cité-city.4925 Pointe-aux-Trembles, cité-city.4941 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 juillet 1974, 106- année, n' 27 4963 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Bureau de révision de l'évaluation Québec Real Estate foncière du Québec: Revision Board: Amos, ville-town (Section Québec).4929 Matane, comté-county.4930 Shefford, comté-county.4930 Éducation Education Municipalité scolaire de: School Municipality of: Blainville-Deux-Montagnes (Nom-Name ch.) 4939 Laurentian (Nom-Name ch.).4940 Richesses narurelles Natural Resources Révocation de droits miniers.4937 Revocation of Mining Rights.4937 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Bauneville, canton-township.4930 Beauport, par.4930 Beauport, par.4931 Cap-de-la-Madeleine, par.4931 Chatham, canton-township.4931 Chicoutimi, par.4931 Dunham, canton-township.4931 Ireland, canton-township.4932 Lynch, canton-township.4932 Orford, cantn-township.4932 Orford, canton-township.4932 Québec, Quartier Saint-Roch Ward, cité-city.4934 Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, par.4932 Saint-Félix-du-Cap-Rouge, par.4933 Saint-Joseph, par.4933 Saint-Martin, par.4933 Sainte-Victoire, par.4933 Trois-Rivières, par.4933 NOMINATIONS APPOINTMENTS Divers: Miscellaneous: Bernier, Marcel (Coroner).4940 Millar.Malcolm (Coroner).4040 Régie de l'assurance- Québec Health maladie du Québec Insurance Board Professionals withdrawn.4925 Professionnels désengagés.4926 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATIONS ACT Révocation de dissolution: Revocation of dissolution: Agence Marquette limitée.4941 Alarie (J.) Construction cie ltée.4941 Argo Transport Company Ltd.4941 Boutique Mi-Laine inc.4941 Burnt Hill Tungstein & Metallurgical Limited 4941 Club du Lac Moïse inc.4941 Compagnie de transport Argo ltée (La).4941 Corne d'Or inc.(La).4941 Entreprises de placements Genève inc.4941 Geneva Capital Ventures Inc.4941 Intersuit Inc.4941 Marquette Agencies Limited.4941 Quartislnc.4941 Weekechum Fish & Game Club Inc.4941 SOUMISSIONS\u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Cap-de-la-Madeleine, c.s.-s.b.(Correction) .4942 Delson, ville-town (Correction).4942 Du Golfe, c.s.-s.b.(Correction).4942 Fleurimont, munie.(Correction).4942 Harricana, c.s.r.-r.s.b.(Correction).4942 Jean-Chapais, c.s.-s.b.(Correction).4942 La Vérendrye, c.s.-s.b.(Correction).4942 Laurenvale, c.s.-s.c.4942 Papineau, c.s.r.-r.s.b.(Correction).4942 Piedmont, munie.(Correction).4942 Pierrefonds, ville-town (Correction).4942 Portneuf, c.s.-s.b.(Correction).4942 St-Charles-Borromée, par.(Correction).4942 Terrebonne, ville-town (Correction).4942 VENTES SALES Licitation Licitation Kakogiannakis M Kakogiannakis et al.4944 Massy Realties Ltd.et al.M Mayer Nicolet.4946 Par Shérifs By Sheriffs Beauharnois Beauharnois Joly r* Vigneault et al.4947 Léger vs Michaud.4948 Hull Hull Maranda vs Dacey.4948 Joliette Joliette Lavallée Girard et al.vs Domaine Grande Vallée .4949 Montréal Montreal Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal vs Desjardins et al.4951 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) M Desjardins et ai.4952 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Desjardins et al.4953 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Péladeau et al.4950 Certil International Ltd.vs Girard, Héritiers- Heirs.4952 4964 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, July 6, 1974, Vol.106, No.S7 Montreal Montreal (suite) (continued) Excellence cie d'assurance-vie (L') vs Trudel.4954 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Desjardins et al.4951 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Desjardins et al.4952 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Desjardins et ai.4953 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Péladeau et al.4950 Québec Québec Dessurcault (J.M.) (1971) Inc.vs Lefaivre et al.4957 General Trust of Canada vs Gagnon.4955 Lauzon, cité-city vs Paré et ai.4956 McDonald, Currie & Cie vs Gérard Proulx .4957 Miville (Claude) inc.vs Pied Carré inc.4956 Pépin (Lauréat) inc.vs Sinota Inc.et al.4954 Trust General du Canada M Claude Gagnon.4955 Taxes Taxes Cookshire, ville-town.4944 SOMMAIRE Arrêtés en conseil.4934 Avis divers.4938 Changement de nom, Loi du.4920 Commission des transports du Québec.4891 Compagnies, avis concernant la Loi des 4873-4936 Curatelle publique.4935 Demandes A la Législature.4924-4941 Ministères.4929-4937-4939 Nominations.4940 Régie de l'assurance-maladie.4925 Renseignements sur les compagnies.4941 Soumissions.4942 Ventes: Licitation.4944 Par shérifs.4947 Pour taxes.4944 SUMMARY Applications to Legislature.4924-4941 Appointments.4940 Change of Name Act.4920 Companies Act, Notices concerning the 4873-4936 Companies Information Act.4941 Departments.4929-4937^939 Miscellaneous Notices.4938 Orders in Council.4934 Public Curatorship.4935 Québec Health Insurance Board.4925 Québec Transport Commission.4891 Sales: Licitation.4944 By Sheriffs.4947 For Taxes.4944 Tenders.4942 nouveautés Ministère des Affaires sociales Régie des rentes du Québec Québec Pension Board Rapport annuel 1973 Québec, 1974.78 p., tabl.stat., 24 cm ISBN 0-7754-1837-4, broché S 1.50 Ministère du Conseil exécutif Office de planification et de développement du Québec Rapport annuel 1972/73 Québec, 1974 70 p.24 cm ISBN 0-7754-1838-2, broché S 1.50 Ministère de l'Éducation La leçon des laits par Lise Lachance Québec.1974.102 p.ISBN 0-7754-1814-5.broché S 2.50 Récit de stages de se.s.a.me.pour les formateurs d'adultes et observations sur la vie des participants dans une dynamique d'apprentissage.Sentences arbitrales en éducation Sentences 0001 à 0100 Québec, 1974.429 p.ISBN 0-7754-1810-2, broché Sentences arbitrales en éducation Sentences 0101 à 0200 Québec.1974.ISBN 0-7754-1811-0, broché i\\ JOIL 137*» \\ bibliothèque nationale 7-50 du québec _ COLLECTION S 2.00 Ce volume traite spécifiquement de l'enseignement religieux.Il montre la place de cet enseignement dans le projet éducatif, les motifs qui fondent la présence de l'enseignement religieux à l'école et les perspectives dans lesquelles cet enseignement doit être donné.l'ouvrage permet au comité catholique de faire un bilan de la situation de l'enseignement religieux à l'élémentaire et au secondaire et de proposer les orientations souhaitées.Tome III \u2014 «Les maîtres et l'éducation religieuse» Québec.1974.ISBN 0-7754-1809-9, broché S 2.00 Le troisième volume aborde le problème de la préparation des maîtres, aussi bien pour l'élémentaire que pour le secondaire.Il comporte une lecture de la situation suivie d'une analyse de ce qu'est ou devrait être le statut de renseignant de la religion à l'élémentaire et au secondaire et se termine par des recommandations du comité concernant la formation initiale et permanente des maîtres en enseignement religieux.Ministère de la Fonction publique Commision de la fonction publique Rapport annuel 1973 Québec, 1974.53 p.24 cm ISBN 0-7754-1829-3, broché S 1.00 Disponible seulement après dépôt à l'Assemblée nationale Ministère de l'Industrie et du Commerce Bureau de la statistique du Québec Fermes de recensement déclarant des cultures ou du bétail classées selon le nombre d'acres ou de tètes déclarées par région agricole et par comté, 1971.Québec, 1974.98 p., tabl., stat.28 cm, (polycopié) ISBN 0-7754-1836-6, broché $ 1.00 \u2022 L'ÉDITEUR OFFICIEL i DU QUÉBEC 675 EST, BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC \"Voies et impasses» Tome II \u2014 «L'enseignement religieux» Québec.1974.ISBN 0-7754-1808-0, broché "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.