Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 10 août 1974, Partie 1 samedi 10 (no 32)
[" fflW OFF AUE8 G3/ PTIE1 EX.2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTIE 1 AVIS JURIDIQUES 10 AOUT 1974 N° 32 OFFICIAL GAZETTE PARTI JURIDICAL NOTICES I GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° SB 5607 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazette officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 5608 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: $1 chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° S3 5609 AVIS JURIDIQUES\tJURIDICAL NOTICES\t\t\t Compagnies \u2014 Loi des\tCompanies Act\t\t\t Lettres patentes (I™ partie)\tLetters Patent (Part I)\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t\t\t Nom / Nam»\tSiège social / Head Office\tIncorporation Date\t\t A.B.C.ELECTRONICS INSTALLATIONS INC.LES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES ABC.INC.1366-0511\t.117, rue St-Jean-Baptiste, Montmagny.\t24\t04\t74 \t\t30\t01\t74 1357-8448\t\t\t\t ADCONEX, SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE INC.Montréal.1368-4394\t\t28\t05\t74 LES ALIMENTS ROCH LTEE.1356-7144\t.2629, boulevard St-Jean-Baptiste, Chicoutimi.\t21\t05\t74 ALLIED BOAT COMPANY CANADA LTD .\t.Rue Peel, Montréal.\t11\t04\t74 COMPAGNIE DES BATEAUX UNIS CANADA LTEE 1355-7913\t\t\t\t \t\t19\t00\t74 HUPPE DEVELOPMENT INC.1356-7277\t\t\t\t \t\t21\t05\t74 RESTAURANT MARK ANDREW INC.1368-3347\t\t\t\t APPROVISIONNEMENT NEPTUNE INC.\t.Sbpt-Iles.\t02\t11\t73 1357-4686\t\t\t\t AUTOBUS VIENS INC.\t\t15\t06\t74 VIENS BUS INC.1356-6005\t\t\t\t SIMON BEAUREGARD INC.1356-7979\t\t.27\t05\t74 BLONDIN 4 POULIN INC.1368-1283\t.800, rue Montrose, Duvernay, Laval\t.06\t06\t74 BOUTIQUE PATTES DE VELOUR8 INC.1357-2236\t\t14\t00\t74 \t\t14\t05\t74 1366-6171\t\t\t\t CANADIAN YOUTH STUDENT SALES INC.\t\t26\t06\t74 LES VENTES DE LA JEUNESSE ETUDIANTE CANADIENNE INC.1366-4307\t\t\t\t CAN DECO LIMITED.CANDECO LIMITEE 1368-8270\t.1155 Dorchester Boulevard West, Suite 3112, Montreal.\t27\t06\t74 5610 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Nom/ Name Incorporation Siège social / Head Office Date 1387 Dollard Street, LaSalle.16 06 74 Route rurale 3, Dunham.16 07 74 5800 Monkland Avenue, Suite 4, 05 06 74 Montreal.74, boulevardGréber, Pointe-Gatineau.07 06 74 2435, rue Watt, local 6, Pare Colbert, 31 01 74 Sainte-Foy Saint-Pacôme.10 06 74 Québec.14 06 74 4928 Carlton Avenue, Montreal.31 06 74 1347, 8ième Rue, Saint-Antoine-des- 02 07 74 Laurentides.16728, boulevard Pierrefonds, Pierre- 26 06 74 fonds.50, rue Fraser, Sept-Iles.21 05 74 219A, rue Notre-Dame, Repentigny.11 06 74 4074, chemin de Tilly, Saint-Antoine- 10 04 74 de-Tilly.9, rue Jobin, Saint-Timothée.27 02 74 10000.rue London, Montréal-Nord.08 07 74 116, chemin St-Jean, Laprairie.27 06 74 6700, boulevard Taschereau, Brossard.20 06 74 Montréal.14 06 74 35, Aberdeen, West mount.20 02 74 2276, Desjardins, Saint-Hyacinthe.04 06 74 Montréal.07 06 74 THE CAPTAIN'S WHARF RESTAURANT INC.LE RESTAURANT LE QUAI DU CAPITAINE INC.1356-5660 CLAUDE CAYOUETTE INC.13674603 LE CENTRE DE TESTS ALLEREX INC.ALLEREX TESTING CENTRE INC.1368-6391 CENTRE DU SPORT MERCIER 4 PROULX LTEE- MERCIER & PROULX SPORT CENTER LTD.1356-3697 CHAUSSURES TALBOT (1974) INC.TALBOT SHOES (1974) INC.1357-5766 LES CIMENTS DE KAMOURASKA INC.KAMOURASKA CEMENT INC.1357-1013 CLOTRAC INC.1367-2102 COMPAGNIE DE CONSTRUCTION OAKLAND LTEE.OAKLAND CONSTRUCTION COMPANY LTD.1368-4873 COMPAGNIE DE GESTION Y.W.F.INC.1368-8502 CONSTRUCTION BAILLARGE LTEE.1368-7843 CONSTRUCTION BELLEY 4 LECAVALIER LTEE.1366-7128 CONSTRUCTION CLAUDE LAPLANTE INCORPOREE.1356-7284 CONSTRUCTION ELMO INC.ELMO CONSTRUCTION INC.1356-8085 CONSTRUCTION F.MARTEL INC.1367-6764 CONSTRUCTION RABINO LTEE.RABINO CONSTRUCTION LTD.1368-7538 CONSTRUCTIONS JANNICK INC.JANNICK CONSTRUCTION INC.1368-8155 CONSTRUCTIONS MAISONS RONDES INC.1368-7595 CORPORATION ARTHUR BAILEY.ARTHUR BAILEY CORPORATION 1357-2367 LES COSMETIQUES CINQUANTE ET PLUS LTEE., .FIFTY PLUS COSMETICS LTD.1357-4850 CREATIONS FLORALES CASCADE INC.1356-8928 CYLINDRIX MFG.INC.COMPAGNIE DE FABRICATION CYLINDRIX INC.1368-5748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1971,, 106- année, n° 32 5611 Nom / Name DELTA TRANSLATIONS INC.TRADUCTIONS DELTA INC.1366-9116 ARMAND DESROCHERS INC.1366-8340 DIAMOND TRANSPORT INC.TRANSPORT DIAMANT INC.1366-7912 DIESEL DRAPEAU * DUBE INC.1366-4621 S.DOUCETTE ET FILS INC.1357-6238 LES EDITIONS LACOMBE INC.1368-8338 ELECTROLEC INC.1367 0760 W.ENSLIN JEWELLERS INC.LES BIJOUTERIES W.ENSLIN INC.1366-6963 LES ENTREPRISES B.T.INC.1366-2609 LES ENTREPRISES BRUNO ZOCASTELLO INC 1367-6998 LES ENTREPRISES C.F.N.P.INC.1357-6790 LES ENTREPRISES DEL LTEE.1368-6084 LES ENTREPRISES G.N.C.INC.O.N.C.ENTERPRISES INC.1366-1824 LES ENTREPRISES G.O.C.INC.1367-1807 LES ENTREPRISES JEAN 4 JEAN LTEE.1354-6403 LES ENTREPRISES LIN LIMITEE.1357-2060 LES ENTREPRISES OUGIRI INC.1366-3200 LE8 ENTREPRISES PRYGO INC.1356-1287 LES ENTREPRISES ROGER LAVERDIERE INC.1368-6928 EPICERIE-RESTAURANT DESGAGNES INC.1356-6973 L'ETAL LAURENTIEN INC.1366-8324 LES EVALUATIONS VILLE-MARIE INC.1368-1424 EXCAVATIONS FONTAINE INC.FONTAINE EXCAVATIONS INC.1368-6803 Incorporation Siège social / Head Office Date 655 Dorchester Boulevard West, 03 06 74 Suite 1610, Montreal 1627, Maufils.Québec.27 06 74 8936 Provence, Saint-Léonard.24 05 74 1245, rue Godin.Saint-Vincent- 10 05 74 de-Paul.Laval Saint-Omer.26 06 74 616.boulevard Dorchester ouest, 28 06 74 suite 1010, Montréal Québec.06 06 74 54 King Street East, Sherbrooke.17 05 74 Sherbrooke.26 03 74 293.Gamache.Sept-Iles.04 07 74 Saint-Georges-Ouest.11 06 74 4, Place Ville-Marie, No 512, 11 06 74 Montréal 109, Promenade des Iles, Chomedey, 02 06 74 Laval.1318.3e Avenue Nord, Saint- 12 06 74 Rédempteur.La Plaine.11 03 74 1001.avenue Levis.Val d'Or.13 06 74 2046.rue Roussel, Chicoutimi-Nord 06 05 74 Rimouski.29 04 74 2070, boulevard De Blois, Duvernay, 17 06 74 Laval.30, rue Royale, Saint-Bernard- 16 05 74 sur-Mer, Ile-aux-Coudres 1424, Bellevue, Ancienne-Lorette.27 05 74 606.Alexandre.Pont-Viau.Laval.07 06 74 11460.l'Archevêque.Montréal Nord.09 07 74 5612 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 10, 1974, Vol.106, No.82 Nom / Name J.A.FANNING INVESTMENTS INC.LES PLACEMENTS J.A.FANNING INC.1366-3061 FARBEC INC.1366-3160 FER ORNEMENTAL JEAN-GUY ROBERT INC.1368-4071 LA FERME QUATRE SOLEILS INC.FOUR SUNS FARM INC.1368-7033 FRAN LEX ENTERPRISES INC.LES ENTREPRISES FRANLEX INC.1355-9372 G.E.CARTON DEVELOPMENT CORPORATION LTD.CORPORATION D'AMENAGEMENT G.E.CARTON LTEE 1356-8589 GARAGE NATIONAL ST-JEAN INC.1368-6704 CLAUDE GERMAIN ET ASSOCIES LTEE.1368-6662 GESTION HEGIRE INC.HEGIRE HOLDINGS INC.1357-3001 GESTION TRANS-ESTRIE INC.1356-6864 GESTION ULTRON LIMITEE.1368-5565 PHILIP GOODMAN INC.1368-6506 IRVING GOTTHEIL INSURANCE INC.ASSURANCES IRVING GOTTHEIL INC.1368-4287 GROUPE DE LA CIBLE LTEE.TARGET GROUP LTD.1368-6936 LES HABITATIONS CLOMONT INC.1357-1203 JEAN HAMEL INC.1357-1583 LES IMMEUBLES GRENADA LTEE.GRENADA REALTIES LTD.1368-6656 IMMEUBLES QUEBEC-MARITIMES INC.QUEBEC-MARITIMES REALTIES INC.1357-5840 LES IMMEUBLES VIGNON INC.1357-1898 IMPORTATIONS EUROBEL LTEE.EUROBEL IMPORTS LTD.1368-6134 LES INDUSTRIES BELLECHASSE INC.1357-1849 Incorporation Siège social / Head Office Date Cowansville.06 06 74 550.boulevard Hamel.Québec.06 05 74 386.rue Principale.8aint-Mathieu- 24 06 74 4, Place Ville-Marie, suite 612, 17 06 74 Montréal.101 Douglas Shand, Apt.16.22 04 74 Pointe-Claire.Montréal.28 05 74 11435.rue Notre-Dame.Montréal- 14 06 74 Est.1290, rue Visitation, Montréal.14 06 74 1010 St.Catherine Street West, 18 06 74 Suite 1210, Montreal.346, Saint-Hubert.Granby.21 05 74 Montréal.06 06 74 5620 Greenwood Avenue, Côte 13 06 74 Saint-Luc.1994 Romiti, Chomedey, Laval.28 05 74 328 Victoria Avenue, Suite 10, 17 06 74 Westmount.925, boulevard Maloney, Torn piéton .06 06 74 410, 18ème Avenue, Saint-Jean, 10 06 74 Deschaillons.1 Place Ville-Marie.Suite 3635, 06 06 74 Montréal.Sainte-Foy.22 02 74 Aima.12 06 74 5333 Casgrain, Room 202, Montreal.11 06 74 400, 6e Rue, Daveluyville.12 06 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' armée, n° SS 5613 Nom / Name LES INDUSTRIES DE PALETTES UNIVERSELLES INC.UNIVERSAL PALETTES INDUSTRIES INC.1356-9462 INSTITUTION CHARLEMAGNE INC.1368-6878 J.G.JACQUES INC.1356-3028 KATER STEEL LTD.ACLER KATER LTEE 1368-0111 KORFUS REALTY CO.LTD.COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE KORFUS LTEE 1356-8043 ROGER LABARRE INC.1355-2708 LAVOIE & SONS CONSTRUCTION INC.LES CONSTRUCTIONS LAVOIE & FILS INC.1356-6112 LOCATION L.P.INC.L.P.LEASING INC.1365-6808 LOCATION OSTIGUY INC.OSTIGUY RENTAL INC.1357-2870 MAISON DE PEINTURE RUE ONTARIO LTEE.1368-4238 LES MAISONS SYRISOTA LIMITEE.SYRISOTA HOMES LIMITED 1367-1490 MANUFACTURIER A.O.INC.1367-4841 MARCHE BARIL INC.1357-3696 MARCHE N.OUIMETTE INC.1368-0889 MATOUFF SPORTS INC.SPORTS MATOUFF INC.1356-7607 MEGESTAL LIMITEE.1356-9249 MERTER INC.1356-9652 MILDRED INVESTMENTS INC.LES INVESTISSEMENTS MILDRED INC.1368-5607 THE MILLER GROUP LTD.LE GROUPE MILLER LTEE 1368-3016 MARC H.NADEAU LTEE.1356-1568 NAVCOM INC.1355-1742 Incorporation Siège social / Head Office Date 140, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice.29 05 74 Montréal.28 02 74 Saint-Romain.13 06 74 600 Dawson, Mont-Royal.11 06 74 2195 Depatie Street, Saint-Laurent.24 05 74 Richmond.26 03 74 161, rue Principale, Sainte-Jeanne d'Arc 15 05 74 Cap Chat.08 04 74 400, boulevard Richelieu, Richelieu.18 06 74 1104 Ontario Street East, Montreal.25 05 74 Pierxefonds.11 03 74 710, Place d'Israëli, Chomedey, Laval.27 03 74 Lorrainville.25 06 74 Rue Principale, Sutton.03 05 74 1000, boulevard Gouin ouest, Montréal 21 05 74 Montréal.25 06 74 Grande-Rivière.03 06 74 1117 St.Catherine Street West.02 07 74 Room 700, Montreal.Suite 1715, Place Ville-Marie, Montreal 16 06 74 East-Broughton.29 04 74 Chicoutimi-Nord.22 03 74 5614 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date 375Rabastalière West,Saint-Bruno.19 06 74 Montreal.28 05 74 Route rurale 1, Saint-Sauveur-des- 31 01 74 Monts Drummondville.18 04 74 10977, Masse, Montréal-Nord.01 04 74 165, Place Repentigny, Repentigny.23 04 74 Lauzon.27 02 74 880, chemin Ste-Foy, suite 840, Québec 20 06 74 8335.1ère Avenue, Charlesbourg.05 06 74 Montreal.11 06 74 Saint-Clet.03 05 74 4290, rue St-Félis, Cap-Rouge.21 06 74 3510 Mountain Street, Apt.71, 05 03 74 Montreal.Montréal.17 06 74 4629, rue Amiens, Montréal Nord.30 05 74 907, boulevard Taschereau, 21 06 74 Longueuil.3467, rue Laval, suite 2, Montréal____ 11 06 74 5333 Casgrain Avenue, Room 602, 03 06 74 Montreal.24 rue Gravel Saint-Romuald- 27 03 74 d'Etchemin.16 Clairevue Boulevard West, 18 06 74 Saint-Bruno.460, boulevard Chomedey, Laval.28 01 74 NETTOYEUR MONT ST-BRUNO INC.MONT ST.BRUNO CLEANERS INC.1368-7744 OLYMPIA OPTICAL LTD.OPTIQUE OLYMPIA LTEE 1368-4477 PAUL OUIMET EXCAVATION INC.EXCAVATION PAUL OUIMET INC.1357-2433 LES OUTILLEURS ARPEX INC.1355-9083 LES OUTILS I.C.T.LTEE.I.C.T.TOOLS LTD.1366-4498 PANTIQUE INC.1367-8867 FERNAND PAQUET INC.1357-2441 PELI LTEE.1357-3134 PEPINIERE BOURBEAU INC.1357-0726 PERBEAU AUTO BODY LTD.CARROSSERIE PERBEAU LTEE 1368-6126 PHARAND TRANSPORT INC.TRANSPORT PHARAND INC.1356-3556 PLACANO INC.1356-5882 LES PLACEMENTS DE LA FAMILLE GLASS LTEE.GLASS FAMILY HOLDINGS LTD.1367-4761 LES PLACEMENTS LA TOSCANE LTEE.TUSCANY HOLDINGS LTD.1357-2714 PLOMBERIE OUELLET INC.1368-4733 POLISSAGE & PLACAGE G.G.INC.G.G.BUFFING & PLATING INC.1356-7268 PRODUCTIONS PIERRE DUFRESNE INC.1368-6290 LES PRODUITS DE CUIR BARON INC.BARON LEATHER PRODUCTS INC.1368-5193 REMBOURRAGES ST-ROMUALD INC.1355-3029 RESTAURANT JE REVIENS LTEE.1368-7504 ROY & RACINE INC.1357-4660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 38 5615 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date RUNO DEVELOPMENTS LIMITED.LES AMENAGEMENTS RUNO LIMITEE.1368-4303 SALON DE L'ESPACE ET DE L'AERONAUTIQUE DE MONTREAL INC.MONTREAL AERONAUTICS AND SPACE EXHIBITION INC.1356-6245 SAM STATIONERY INC.PAPETERIE SAM INC.1368-2091 SEOUL IM PORTS INC.LES IMPORTATIONS SEOUL INC.1355-6709 SERVICE ET RENOVATION FOURNIER DE SHERBROOKE INCORPOREE.1354-3202 LES SERVICES MER-PA INC.1356-2459 SHAABAN SPORTSWEAR INC.LES VETEMENTS DE SPORT SHAABAN INC.1368-6837 SINAMONE INC.1357-3522 SIÇARO INC.1356^-5462 SOCIETE DE GESTION LAROBI INC.1357-4777 LA SOCIETE DUMEL INC.1356-6237 SOCIETE F.R.INC.1366-2202 SOVITAL LTEE.1356-1477 SYSTEME DE CONTROLE SOLAIRE STYRO INC.STYRO SUN CONTROL SYSTEMS INC.1368-8924 TESCA CONSTRUCTION INC.CONSTRUCTION TESCA INC.1356-6211 TIKOR CONSTRUCTION LIMITED.CONSTRUCTION TIKOR LIMITEE 1368-8379 VARIETES DESCHESNES INC.1356-6161 VENTILATION C.A.S.(MAURICIE) INC.1368-6894 LES VETEMENTS DE SPORT TRANS-CANADA INC.TRANS-CANADA SPORTSWEAR INC.1368-8007 LAURENT WILSON INC.1357-4819 Montreal.28 05 74 4101, rue Jarry est, chambre 300, Montréal.15 05 74 4345, Notre-Dame, Laval.13 05 74 Montreal.08 04 74 417 Gait ouest, Sherbrooke.01 04 74 197, Avenue Riverin, Chicoutimi.160 St.Viateur Street East, Montreal.169, Ste-Thérèse, app.4, Rimouski, Rimoueki.Levis.7855.rue Serge, LaSalle.1434, Saint-Georges, Ancienne-Lorette.1198, rue Colbert, Saint-Foy- 75, rue Principale est, Farnham.2045 Jessop, Chomedey, Laval.02 06 74 05 03 74 25 06 74 14 06 74 01 06 74 15 06 74 03 05 74 30 04 74 08 07 74 6420 Victoria Avenue, Montreal.15 05 74 523 Stinson Street.Saint-Laurent.28 06 74 66, 6e Avenue est, La Sarre.3390, 19e rue, Grand'Mère.Montreal.17 06 74 17 06 74 26 06 74 Pierrefonds.25 02 74 58083-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Debjardins.58083-o Pierre Debjardins, Director of the Companies Service. 5616 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Administrateurs Directors Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs whose names follow have changed the number of their directors tel qu indiqué ci-après.as indicated hereinafter.Date de Nombre d'administrateurs # constitution Number of directors Nom de la compagnie -__-\u2014- Name of Company Date of Ancien nombre Nouveau nombre incorporation Previous number New number AUTOS BELANGER LEVIS INC.BELANGER AUTOS LEVIS INC.733644\t09\t08\t73\t4\t3 BELL ASBESTOS MINES, LTD.2623-36\t20\t11\t36\t14\t13 LE GROUPE CANEST LTEE 730451\t01\t02\t73\t3\t4 LEWIS SHOES LIMITED 4883-69\t07\t10\t69\t11\t13 CLUB DE BASEBALL DE LAVAL-DES-RAPIDES INC.723901\t12\t07\t72\t3\t9 CLUB DE RECREATION DU MONOIR THISTLE.THISTLE MANOR RECREATIONAL CLUB 1367^916\t06\t02\t74\t3\t6 DOMAINE MARLBORO INC.1767-70\t20\t04\t70\t4\t3 731226\t19\t08\t73\t3\t4 GESTION COGEMAR LIMITEE.COGEMAR MANAGEMENT LIMITED 1365-6337\t05\t04\t74\t3\t7 LABBE 4 FILS INC.2369-67\t26\t05\t67\t3\t4 LEPINE LTEE.2644-68\t28\t05\t68\t6\t6 MAGOON POINT FISH AND GAME CLUB INC.CLUB DE CHASSE ET DE PECHE DE LA POINTE MAGOON INC.729488\t01\t12\t72\t6\t9 RADISSON FURNITURE LIMITED 736748\t29\t12\t73\t3\t6 PLACE DESJARDINS INC.3125-71\t09\t06\t71\t7\til PROVIGO INC.16650-61\t14\t11\t61\t12\t9 RESTAURANT ROMA INC.1921-64\t15\t05\t64\t4\t3 S.M.A.(SOCIETE DE MATHEMATIQUES APPLIQUEES) INC.132-64\t09\t01\t64\t14\t7 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins 58083-o Pierre Debjardins.5S083-o Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année.n° 32 5617 Changement de nom\tChange of name\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivants:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of:\t\t\t Nouveau nom / New name\tAncien nom Former name\tIncorporation Date\t\t LES ARMOIRES ET TAPIS LAFERTE LTEE____\tTAPIS LAFERTE INC.\t06\t07\t72 723807\t\t\t\t LES ATELIERS ELECTRONIQUES DE LA RIVE SUD INC.LES ATELIERS ELECTRONI-SOUTH SHORE ELECTRONIC WORKSHOPS INC.QUES TAVERNIEJt INC.721933 TAVERNIER ELECTRONIC WORKSHOPS INC.\t\t10\t04\t72 COMPAGNIE DU CHANDAIL BRAVO LTEE.BRAVO SWEATER COMPANY LTD.667-69\t.CHOMEDEY SWEATER COMPANY LTD.COMPAGNIE DU CHANDAIL CHOMEDEY LTEE\t04\t03\t63 CORPORATION FONTEL.FONTEL CORPORATION 2844-66\t.HOTEL MOTEL FONTAINEBLEAU (MONTRÉAL) INC.\t07\t07\t66 ENTREPRISES CLAUCAR INC.\t.BETON CHAMPLAIN INC.\t31\t01\t74 740471\t\t\t\t EXCAVATION RICARD INC.3605-71\tLAJEUNESSE 4 RICARD INC.\t02\t07\t71 FERMONT INC.\t.APOLUPAK INC.\t15\t09\t72 726188\t\t\t\t GALLAHER FISH AND GAME CLUB.CLUB DE CHASSE ET PECHE GALLAHER C.C.P.27-51\tGALLAHER FISH AND GAME CLUB\t11\t05\t51 GARAGE R.LACHAINE INC.\t.RILAC EXCAVATION LTEE_____\t30\t01\t«4 445-64\t\t\t\t HARTOLIN HOMES INC.\t.HARTOLIN REALTY INC.\t26\t02\t74 LES MAISONS HARTOLIN INC.1354-8110\tIMMEUBLES HARTOLIN INC.\t\t\t LES MEUBLES GRANCO INC.GRANCO FURNITURE INC 1368-0871\t.LES MEUBLES GRENCO INC.GRENCO FURNITURE INC.\t03\t05\t74 ASCENSEURS NAGLE INC.12242-54\tINC.\t02\t09\t54 PLACIMAD INC.3793-69\t.CENTRE DE COIFFURE MASCULINE (SHERBROOKE) INC.\t00\t08\t69 \t.LIBRAIRIE SAUTIER INC.\t27\t02\t74 1367-1672\t\t\t\t \t.SERANA INC.\t30\t09\t69 4703-69\t\t\t\t \tPIERRE LEGAULT INC.\t05\t10\t66 4372-66\t\t\t\t 58083-o Le directeur du tervice dee compagnies, Pierre Debjardins.58083-q Pierre Debjardins, Director of the Companies Service. 5618 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, Mi, Vol.106, No.82 Lettres patentes (3* partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- conatituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ASSOCIATION DES SPARTIATES MOLAOI DE MONTREAL.Montréal.22 03 74 MOLAOI SPARTANS ASSOCIATION OF MONTRÉAL 1356-2062 COSEM INC.1355-4050 JEUNE CHAMBRE DE RAGUENEAU INC.1354-2253 LIGUE DE BASEBALL MIDGET DES CANTONS DE L'EST INC.1356-8001 LE REVEIL DE8 AVEUGLES DE GRANBY INC.1368-2034 SERVICE DE L'AIDE AUX COUPLES (S.A.C.) DE GATI- NEAU INC.1355-7178 Longueuil.04 07 74 Ragueneau.26 04 74 Granby.24 06 74 586, rue Principale, Granby.01 06 74 206, rue Ménard, Gatineau.04 06 74 58083-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjaroins.58083-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires à: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes CENTRE PEDIATRIQUE CHATEAU PIERRE- 20 03 74 FONDS INC.1365-7814 CINEVIC INC.13 06 69 2921-69 LA CORPORATION DE L'HOPITAL CHAM- 14 08 68 PLAIN DE VERDUN 2614-68 LES ENTREPRISES WORKMAN INC.29 01 71 WORKMAN ENTERPRISES IKC.416-71 G.FOURNIER LTEE.29 04 66 1815-66 04 06 74 Ancien nom / Former name: HOPITAL PEDIATRIQUE CHATEAU PIERREFONDS INC.06 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital 03 07 74 Augmentant la valeur des biens immobiliers / Increasing the value of immoveable properly 07 06 74 28 03 74 1) Ancien nom / Former name: IRVING SAMUEL ENTERPRISES INC.2) Modifiant les pouvoirs / Modifying the -'viers odifiant le capital / Altering the capital Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers pow 3) Mo< GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 82 5619 Nom / Name Incorporation L.P.8./ S.LJ>.Date Date Modifications Change» MAISONS MOBILES METRO LTEE.METRO MOBILE HOMES LTD.733530 MERMIX CORPORATION.I A CORPORATION MERMIX 731671 PONT MERCIER SHOPPING CENTRE INC.11815-58 08 08 73 21 06 74 Ancien nom / Former name: MAISONS MOBILES MINTO LTEE MINTO MOBILE HOMES LTD.05 04 73 03 06 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.26 06 58 17 04 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers Le directeur du service des compagnies, 58083-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 58083-o Director of the Companies Service.Abandon de charte\tSurrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Name\tIncorporation Dissolution Date Date AUTOBUS DE LA BAIE DEB HA! HA! INC.2664-69 AUTODROME GENTILLY INC.OENTLLY SPEEDWAY INC.2338-67 BAN ARA INVESTMENT CORP.10822-58 DOUBLE KNIT MFG.CORP.10455-61 FRANCO-AMERICAN FUR SKINS LTD.1717-66 THE OASPESIAN FOREST PROTECTIVE ASSOCIATION, LIMITED L'ASSOCIATION GASPESIENNE DE PROTECTION DES FORETS, LIMITEE 764-17 LA GRANGETTE ROUGE LTEE.2217-69 GREENFIELD PARK DONUTS LTD.2923-63 KENO LIMITEE.4767-66 NORCANDA QUEBEC LIMITED.12289-58 L'OEUVRE DES LOISIRS DE PLESSISVILLE, INC.14646-68 SAYKALY AGENCIES LTD.14108-66 SOCIETE DES INFIRMIERES VISITEU8ES DE TROIS-RIVIERES ET CAP-DE-LA-MADELEINE INC.15629-61 06 06 69 23 05 67 13 03 68 06 02 61 12 04 65 09 06 17 09 05 69 06 07 63 02 11 65 23 06 68 16 12 58 25 01 67 27 07 62 09 08 74 19 07 7* 28 07 7* 02 08 74 14 12 73 02 08 74 09 08 74 02 08 74 12 07 74 02 08 74 02 08 74 02 08 74 19 07 74 5620 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Nom / Same SOCIETE D'HABITATION DE ST-ROCH INC.3787-68 REAL INVESTMENT CORP.10821-58 Le directeur du service dee compagnies, 58083-o Pierre Desjardins.DAILY PICK-UP & DELIVERY LTD.Avis est par les présentes donné que « DAILY PICK-UP & DELIVERY LTD.», constituée en vertu de la Loi des compagnies s'adressera au ministre des institution financières compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Contrecoeur, le troisième jour de juillet 1974.Le président, 58088-o Antoine De Rome.Incorporation Dissolution Date Date 21 08 68 13 08 74 13 03 68 26 07 74 Pierre Debjardins, 58083-o Director of the Companies Service.DAILY PICK-UP & DELIVERY LTD.Notice is hereby given that \"Daily Pick-UP & DELIVERY LTD.\" incorporated under the Companies Act will apply to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Contrecoeur, this third day of July 1974.Antoine De Rome, 58088-o President.EDIFICE MATTEAU INC.Avis est par les présentes donné que « EDIFICE MATTEAU INC.», une compagnie incorporée selon la Loi des compagnies et ayant son siège social à Shawinigan, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Shawinigan le 18e jour de juillet 1974.Le secrétaire.58089-o J.A.W.Matteav.EDIFICE MATTEAU INC.Notice is hereby given that \"EDIFICE MATTEAU INC.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Shawinigan will apply to the Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Shawinigan, this 18th day of July 9174.J.A.W.Matteau, 58089-o Secretary.HIGHMONT CORPORATION LIMITED Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la Loi des compagnies la compagnie « HIGHMONT CORPORATION LIMITED » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie, Frumkin, Feldman & Glazman.Place du Canada - suite 995, Montreal.Que.58090 MICRO-DOC INC.Prenez avis que la compagnie « MICRO-DOC INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 22 juillet 1974.Les procureurs de la requérante, Levasseur & Ouelllet.2 Place Québec.Québec.58094-o HIGHMONT CORPORATION LIMITED Notice is hereby given under the provisions of the Companies Act that \"HIGHMONT CORPORATION LIMITED\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Frumkin, Feldman & Glazman, Attorneys for the Company.Place du Canada - suite 995, Montreal, Que.58090-o MICRO-DOC INC.Notice is given that \"MICRO-DOC INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, July 22, 1974.LeVASSEUR & ouellet, Attorneys for Petitioner.2 Place Québec, Québec.58094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5621 EUGENE BEDARD INC.Avis est par les présentes donné que « EUGENE BEDARD INC.» une compagnie constituée selon la Loi des compagnies et ayant son siège social à Ste-Julie Station (Laurierville), district de Mégantic, déposera auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, une requête pour abandon de charte, tel que prévu par la Loi des compagnies.Signé à Montréal, district de Montréal, ce 20e jour de juin 1974.Les procureurs de la compagnie, Lefrançois & Benoit.5325 est, Jean-Talon 202, Montréal.58087-o EUGENE BEDARD INC.Notice is hereby given that \"EUGENE DEDARD INC.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Ste.Julie Station (Laurierville), district of Mégantic, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, district of Montreal, this 20th day of June 1974.Lefrançois & Benoit, Attorneys for the Company.5325 Jean-Talon East 202, Montreal.58087-q IMMEUBLES MATTEAU LIMITEE Avis est par les présentes donné que « IMMEUBLES MATTEAU LIMITEE» une compagnie incorporée selon la Loi des compagnies et ayant son siège social à Shawinigan, demande] a au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Shawinigan le 18e jour de juillet 1974.Le secrétaire, 58091-o J.A.W.Matteau.IMMEUBLES MATTEAU LIMITEE Notice is hereby given that \"IMMEUBLES MATTEAU LIMITEE\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Shawinigan, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Shawinigan, this 18th day of July 1974.J.A.W.Matteau, 5809l-o Secretary.SENOPO CORPORATION LTD.Avis est, par les présentes, donné que la compagnie « SENOPO CORPORATION LTD.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies de la province de Québec et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 24e jour de juillet 1974.Les procureurs de la compagnie, Johnston, Heenan & Blaikie.CP.1086, Station « B » Montréal 110, Que.58095-o SENOPO CORPORATION LTD.Notice is hereby given that \"SENOPO CORPORATION LTD.\", a company incorporated under the Companies Act of the Province of Québec, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th day of July, 1974.Johnston, Heenan & Blaikie, Attorneys for the Company.CP.1086, Station \"B\" Montreal 110, Que.58095-o KLEIN & SHILLER INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « KLEIN & SHILLER INC.», corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 18e jour de juillet 1974.Les procureurs de la compagnie, Kliger & Kliger.1255, Carré Phillips-701, Montréal, Québec.58109 KLEIN & SHILLER INC.Notice is hereby given that \"KLEIN & SHILLER INC\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 18th day of July 1974.Kliger & Kliger, Attorneys for the company.1255 Phillips Square-701, Montreal, Québec.58109-o 5622 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 LES INVESTISSEMENTS BRILLANT LTEE Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, « LES INVESTISSEMENTS BRILLANT LTEE » donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission de distribuer son actif, d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Rimouski, P.Q., ce 19e jour de juin 1974.Le secrétaire, 58092-o André Poisson.LAROUCHE ET GALIPEAU INC.Avis est donné que « LAROUCHE ET GALIPEAU INC.», une corporation légalement constituée, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, J.-Arthur Desilets, notaire.500, boul.St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, Que.58093-o ST-YVES NAVIGATION INC.Prenez avis que la compagnie « ST-YVES NAVIGATION INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Jean-Pierre Roy.126, St.Pierre, Québec, Que.58096-o GENERAL PRODUCTS COMPANY Avis est par les présentes donné que « GENERAL PRODUCTS COMPANY », compagnie incorporée en vertu de la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de ladite Loi.Donné à Montréal, ce 10 août 1974.Les procureurs de la compagnie, schwisberg, GoLT & benson.1010 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, Que.58123-0 HEBREW COVSUMPTIVE AID ASSOCIATION OF CANADA INC.Avis est par les présentes donné que « HEBREW CONSUMPTIVE AID ASSOCIATION OF CANADA INC.», une association légalement constituée sous la troisième partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte sous l'autorité de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 3e jour de juillet 1974.Le secrétaire, 58124-0 J.Retter.LES INVESTISSEMENTS BRILLANT LTEE Pursuant to the provisions of the Companies Act, \"LES INVESTISSEMENTS BRILLANT LTEE' hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to distribute its assets, for leave to surrender its charter, for cancellation of its charter and for the dissolution of the Company.Rimouski, P.Q., this 19th day of June, 1974.André Poisson, 58092-o Secretary.LAROUCHE ET GALIPEAU INC.Notice is given that \"LAROUCHE ET GALIPEAU INC.\", a corporation duly incorporated, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.J.-Arthur Desilets, Notary, Attorney for the Company.500, boul.St-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, Que.58093-o ST-YVES NAVIGATION INC.Notice is given that \"ST-YVES NAVIGATION INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jean-Pierre Rot, Attorney for the Company.126 St.Pierre, Québec, Que.58096 GENERAL PRODUCTS COMPANY Notice is hereby given that \"GENERAL PRODUCTS COMPANY\", a corporation incorporated under the Companies Act, and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 10th day of August, 1974.schwisberg, GoLT & benson, Attorneys for petitioner.1010 St.Catherine St.West, Montreal, Que.58123-0 HEBREW COVSUMPTIVE AID ASSOCIATION OF CANADA INC.Notice is hereby given that \"HEBREW CONSUMPTIVE AID ASSOCIATION OF CANADA INC.\", an association incorporated under Part III of the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the province of Québec, for leave to surrender its charter under |the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 3rd day of July, 1974.J.Retter, 58124-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1971,, 106' année, n* 82 5623 Siège social (Article 84) Head office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci- whose names follow have changed their head office as indicated après.hereinafter.Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address AMPAK LIMITED.07 04 55 Montreal.69 Eastern Place, Saint- 10929-55 Pierre.APPLIED RESEARCH PRODUCTS LTD.05 04 68 Montreal.806.rue Pratt, Outremont.1572-68 BLACK LAKE TELEDIFFUSION INC.01 10 56 Black-Lake.16, rue Notre-Dame sud, 12972-66 Robertsonville.BOIS DE CONSTRUCTION M.LONGPRE INC.17 06 69 278.rue Visitation, 45, rue des Gouverneurs, M.LONGPRE LUMBER INC.Joliette.Repentigny.2931-69 BOREC INC.08 02 73 Montréal.821, rue Plante, Duvernay.730569 Laval.DAVID BROWNSTEIN INC.09 05 69 1062 St.Aubin Street, 189 Harland Street, 2107-69 Saint-Laurent.Hampstead.CAPITOL VENDING CO.LTD.20 11 59 76 Duluth Street East, 711 Riddle Street, Dorval.16279-59 Montreal.CARABEE INVESTMENTS LTD.19 03 68 800 Victoria Square, 6533 Parkview Crescent, 1259-68 suite 2204, Montreal.Côte Saint-Luc.CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITEE.03 11 47 607, Place d'Armes, 625, rue Dorchester ouest, CASGRAIN & COMPANY LIMITED Montréal.Montréal.6452-47 CENTRE PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE 28 02 68 Québec.965, avenue Dessane, QUEBEC INC.Québec.649-1968 CHARADE SPORTWEAR LTD.17 02 67 Montréal.225 Chabanel Street West, 669-67 Montreal.CLOVER HOLDINGS INC.05 06 47 Montreal.2127 Guy Street, Montreal.3694-47 CREATIVE KNITWEAR LTD.30 06 69 Montreal.6605 de Gaspé Street, 3196-1969 Montreal.DE FOY CONSTRUCTION INC.17 02 69 2518, chemin Ste-Foy.1449.rue Semple, Québec.740-69 Sainte-Foy.EM-AR DEVELOPMENT CORP.02 06 69 Montréal.20, Place Holtham, 2663-69 Hampstead.JACQUES HURTUBISE INC.05 02 69 10221.62e Avenue.1226, rue St-Louis, 657-69 Montréal.Terrebonne.INTERNATIONAL MERCHANDISING CORP.23 02 53 Montreal.4333.rue Ste-Catherine 3726-53 ouest, Westmount.JARDINS ST-HUBERT INC.26 02 68 8427-A.rue St-Hubert, 629, boulevard Richelieu 884-68 Montréal.nord, Mont-Saint- Hilaire.LANGSNER-FUHRER INC.20 03 59 Montreal.1090 Pratt Avenue, 11667-69 Outremont.LEMAY AUTOBUS LTEE.09 01 64 768 ouest, rue St-Vallier, Laurier-Station.46-64 Québec. 5624 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 3974, Vol.106, No.82 Incorporation Siège social Head office Nom de la compagnie Name of the company\tDate\t\t\tAncienne adresse Previous address\tNouvelle adresse New address LOU-ED INVESTMENTS CO.LTD.17033-59\t31\t12\t59\tMontreal.\t250 Sauvé St.West, \t\t\t\t\tMontreal.MILANO GENERAL REAL ESTATE INC.4279-67\t12\t10\t67\t1 Place Laval, Room 330, Laval.\t8255 St.Lawrence Boulevard, Montreal.731216\t19\t03\t73\t113, rue Lavoie, Saint-Gédéon.\t805, rue Scott, Alma.A(p at t Apurp ,v ASSOCIATES INC\t24\t02\t67\t\t11072 ouest, rue Gouin, 827-67\t\t\t\t\tPierrefonds.PFNNV.TOTT CORPORATION\t09\t02\t66\t\t5455, rue de Gaapé, 572-66\t\t\t\t\tMontréal.PFRRFAT/TT T.MATHIEIT & OTE LTEE\t29\t10\t62\t\t845, boulevard St-Cyrille PERREAULT-MATH1EU & CO.LTD.14343-62\t\t\t\t\touest, Québec.PT.A7.A D'ENFANTS LTEE\t21\t10\t57\t\t7373 Langelier Boulevard, 13074-57\t\t\t\t\tSaint-Léonard.PROMOTION & PLACEMENTS CIE LTEE- PROMOTION & INVESTMENTS CO.LTD.8178-52\t23\t05\t52\t\t2697, rue Malborough Court, Saint-Laurent.LES PROVISIONS ECONOMIQUES LTEE.12394-57\t24\t07\t57\t326, boulevard Hamel, Québec.\t9027, avenue du Park, Montréal.\t10\t01\t63\t\t177, Maplewood, Outre- 171-63\t\t\t\t\tmont.AT.PHONSF.TALBOT A FILS INC\t28\t02\t62\tQuébec.\t155, avenue des Saulnes 10893-62\t\t\t\t\test, Québec.VENDOME PLACEMENTS LTEE.13129-54\t23\t12\t54\t1, Spring Grove Crescent, Outremont.\t434, boulevard Laird, Mont-Royal.\t06\t07\t63\t\t6710 Notre-Dame St.West, 2869-63\t\t\t\t\tMontreal.WILLIAMS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 4203-46\t27\t05\t46\tSherbrooke.\t1356 Russell St., Sherbrooke.WINIKOFF INC.\t06\t03\t69\t\t660, rue Deslauriers, Saint-Laurent.1032-69\t\t\t\t\t 58083-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Debjardins.58083-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Demande à la Législature Application to Legislature La Corporation Ivanhoe Avis public est par les présentes donné que « La Corporation Ivanhoe », corps politique et incorporé, ayant son bureau d'affaires dans les ville et district de Montréal, s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec pour l'adoption d'une loi: \u2014 afin de faire éteindre la servitude et le droit de passage créés par acte intervenu le 9 octobre 1957 entre Westmont Realties Company et Arthur Proven-cher, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Laprairie sous le numéro 51004, grevant partie des lots numéros quatre-vingt-six (86) et quatre- Ivanhoe Corporation Public notice is hereby given that \"Ivanhoe Corporation \", body politic and corporate, having its head office in the City and District of Montreal, shall apply to the National Assembly of Québec for the adoption of an Act in order: \u2014 to have the servitude and the right of way created by the deed made on the 9th of October 1957, between Westmount Realties Company and Arthur Provencher, registered at the office of the registration division of Laprairie under number 51004, extinguished on part of lots numbers eighty-six (86) and ninety-one (91) of GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5625 vingt-onze (91) du cadastre de la Paroisse de Laprairie de la Magdeleine, en faveur des résidus non subdivisés des lots originaires numéros quatre-vingt-quatre (84), quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86) dudit cadastre; \u2014 afin d'établir la procédure à suivre pour aviser les propriétaires des résidus désirant réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu; \u2014 et pour toutes autres fins.Montréal, ce 4 juillet 1974.Les procureurs de la corporation, VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, 57908-29-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.cadastre of the Parish of Laprairie de la Magdeleine, in favour of non-subdivided remainders of original lots numbers eighty-four (84), eighty-five (85) and eighty-six (86) of the said cadastre; \u2014 to determine the procedure to follow to notify the owners of the remainders of the original lots, wishing to claim damages, as the case may be; \u2014 and for all other purposes.Montreal, July 4, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57908-29-4-o Attorneys for the corporation.Vente pour taxes Ville de Pincourt Avis public est, par les présentes, donné que la Commission municipale de Québec, par un arrêté en date du 24 juillet 1974, a ordonné au soussigné, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi de la Commission municipale de Québec (S.R.Q., 1964, c.170), de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Corporation de Ville de Pincourt avec intérêt et frais, et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du conseil de la ville de Pincourt, 944, boul.Duhamel, Pincourt, comté de Vaudreuil, MERCREDI, le QUATRIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi, heure avancée de l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes devenues exigibles le ou avant le 31 décembre 1973 auront été payées avant le moment de la vente.Sale for taxes Town of Pincourt Public notice is, by the present, given that the Québec Municipal Commission, by a decree in date of July 24th, 1974, has ordered the undersigned, in conformity with the dispositions of article 54 of the Québec Municipal Commission Act (R.S.Q., 1964, c.170) to sell the immoveables hereunder designated to satisfy to the payment of the tax arrears due to the Corporation of the Town of Pincourt, with interest and costs, and that in consequence, said immoveables will be sold by public auction in the Town Hall of Pincourt, 944 Duhamel Blvd., Pincourt, County of Vaudreuil, on WEDNESDAY, the FOURTH day of SEPTEMBER, 1974, at TEN o'clock in the morning, daylight saving time.However will be excluded from the sale of immoveables those on which taxes that have become due on or before December 31st 1973, will have been paid before the moment of the sale.Liste des immeubles à être vendus pour non paiement de taxes sans droit de retrait List of immoveables to be sold for non-payment of taxes no right of redemption Nom et adresse Name and address Lessard, André, 6144, rue Briaiid, Montréal 206.Un emplace ner.t situé dans le village de Pincourt, comté de Vaudreuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels ne ia paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot: comme étant une partie du lot numéro cent vingt et un (Ptie 121), i.es .rant six riîds de largeur en front sur le boulevard Duhamel, et sur le bord de la Rivière Ottawa par toute la profondeur qu'il peut y avoir entre ledit boulevard Duhamel et ladite Rivière O-iawa, bornée en front par la Rivière Ottawa, en arrière par le boulevard Duhamel, d'un côté par l'emplacement appartenant à MM.Hamel et Gionet ou représentants et de l'autre côté par un emplacement appartenant à M.Paul Ladouceur ou représentants, et tel que désigné sur un plan fait et préparé par Fernand Lemay, a.o., le vingt et un août, mil neuf cent cinquante-huit, et qui demeure annexé à un acte enregistré au Bureau d'enregistrement de Vaudreuil, sous le numéro 84814.Domers.Dame Gisèle, 9191, boulevard La Salle, Ville LaSalle.Laflèche, Jean-Paul, 197, boulevard Duhamel, Pincourt.Un terrain vacant situé en la ville de Pincourt, dans le comté de Vaudreuil, connu et désigné aux plan et livre de Cadastre .P-121.P-122.An emplacement located in the Village of Pincourt, County of Vaudreuil, known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot: as being a part of lot nu.mber one hundred and twenty-one (Pt.121), measuring six feet in widthin front on Duhamel Boulevard and on the bank of the Ottawa River by all the depth that can be measured between the said Duhamel Boulevard and the said Ottawa River, bounded in front by the Ottawa River, in the rear by Duhamel Boulevard, on one side by an emplacement belonging to Messrs Hamel and Gionet or representatives, and on the other side by an emplacement belonging to Mr.Paul Ladouceur or representatives, and as it is described on a plan made and prepared by Fernand Lemay, q.l.b., on the twenty-first of August one thousand nine hundred and fifty-eight, which plan is attached to a deed registered at the Vaudreuil Registry Office under number 84814.126-70.P-177.A vacant piece of land located in the Town of Pincourt, in the County of Vaudreuil, known and described on the official 5626 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Nom et adresse Name and address Cadastre renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne comme étant composé: de l'Ile Perrot.as comprising: 1.d'une partie du lot originaire numéro cent soixante-dix- 1.A part of original lot number one hundred and seventy-sept (P.177) au cadastre susdit; seven (Pt.177) on the aforesaid cadastre: _ Mesurant en largeur, en front dans sa ligne ouest qui est Measuring in width, in front on its west line, which ih an une ligne brisée, quarante-sept pieds et quatre-vingt-quatre irregular line, forty-seven and eighty-four hundredths feet centièmes de pied (47.84') et cinquante pieds et vingt-quatre (47.84') and fifty and twenty-four hundredths feet (50.24') centièmes de pied (50.24') en arrière, dans sa ligne nord-est, in the rear, on its northeast line, eighty-nine and thirty-five quatre-vingt-neuf pieds et trente-cinq centièmes de pied hundredths feet (89.35'), on one side on its northwest line, two (89.35').d'un côté dans sa ligne nord-ouest deux cent vingt- hundred and twenty-three and twenty-eight hundredths feet trois pieds et vingt-huit centièmes de pied (223.28'), et de (223.28') and on the other side on its southeast line, two hun- l'autre côté dans sa ligne sud-est deux cent soixante et onze dred and seventy-one and twenty-three hundredths feet pieds et vingt-trois centièmes de pied (271.23'); (271.23').Contenant en superficie vingt et un mille huit cent vingt- Covering a surface area of twenty-one thousand eight cinq pieds carrés (21,825 p.c.) le tout mesure anglaise et plus hundred and twenty-five square feet (21,825 sq.ft.), the whole, ou moins: in English measure and more or less; Borné en front à l'ouest par un chemin public (boulevard Bounded in front on the west side by a public road (Duha- Duhamel).en arrière, au nord-est, et d'un côté au nord-ouest mel Boulevard), in the rear, on the northeast side, and on one par autre partie du même lot originaire numéro 177.pro- side located northwesterly, by another part of said original lot priété des « vendeurs » et de « l'acquéreur » et de l'autre côté, number 177, belonging to the \"vendors\" and the \"purchaser\", au sud-est par une autre partie du même lot originaire nu- and on the other side, on the southeast, by another part of said méro 177 vendue ce jour à.Dame Albertine Montpetit La- original lot number 177 sold today to Mrs.Albertine Montpetit flèche, suivant acte de vente passé devant le notaire soussigné Laflèche, in conformity with a deed of sale executed before the sous le numéro 2460 de ses minutes; undersigned notary under number 2460 of his records; Le tout tel que démontré sur un plan préparé par Jacques The whole as shown on the plan prepared by Jacques Briand.Briand, arpenteur-géomètre, en date du quatrième jour de land-surveyor, and dated the fourth day of May, one thousand mai mil neuf cent soixante-six (1966) portant le numéro nine hundred and sixty-six (1966), bearing number Pt.200, P.200, lequel plan demeurera annexé aux présentes, après said plan shall remain attached to the presents, after having avoir été signé pour fins d'identification par les parties à been signed for identification purposes by the parties thereto 1 acte et contresigné par le notaire soussigné; and countersigned by the undersigned notary; 2.Dune autre partie du lot originaire numéro cent soi- 2.Another part of original lot number one hundred and xante-dix-sept (P.177) au cadastre susdit; seventy-seven (Pt.177) on said cadastre; Mesurant environ soixante-huit pieds et cinq dixièmes de Measuring about sixty-eight and five tenths feet (68.5') pied (68.6') de largeur sur toute la profondeur comprise entre in width by all all the depth that can be measured between le chemin public (boulevard Duhamel) et la Rivière Ottawa, the public road (Duhamel Boulevard) and the Ottawa River, mesure anglaise et plus ou moins; English measure, more or less; Bornée en front par le chemin public (boulevard Duhamel) Bounded in front by the public road (Duhamel Boulevard), en arrière par la Rivière Ottawa, d'un côté par autre partie in the rear by the Ottawa River, on one side by another part of ^u lot originaire numéro 177 propriété de Monsieur Roland original lot number 177 belonging to Mr.Roland Laflèche, and Laflèche, et de 1 autre côté par autre partie du lot originaire on the other side by another part of original lot number 177 quéreur demeurant la propriété des vendeurs et de l'ac- remaining the property of the vendors and the purchaser.Pour localiser cet emplacement, sa ligne nord-ouest est le To locate this emplacement, its northwest line is the exten- prolongement en ligne droite de la ligne nord-ouest de la sion in a straight line of the northwest line of that part of partie du lot originaire numéro 177 ci-dessus décrite au para- original lot number 177 hereinabove described in paragraph 1.graphe 1.Ainsi que le tout se trouve présentement.As the whole now subsists.Bellantoni, Leonardo.96, Allice, Guelph, Ontario.178-333-40.Varanisi, Salvatore, 220, Concord Avenue, Toronto, Ontario.178-333-42.Varanisi, Salvatore, 220, Concord Avenue, Toronto, Ontario.178-333-43.Varanisi, Salvatore, 220, Concord Avenue, Toronto, Ontario.178-333-44.Prior Land and Housing, 236, Meloche, Ville St-Laurent.79rP-165.Partie de la subdivision numéro cent soixante-cinq du lot Part of subdivision number one hundred and sixty-five of originaire numéro cent soixante-dix-neuf (179-P165) audit original lot number one hundred seventy-nine (179-Pt.165) on cadastre, mesurant soixante pieds (60 ) de largeur par une said cadastre, measuring sixty feet (60') in width by a depth of profondeur de cent pieds (100') mesure anglaise et plus ou one hundred feet (100') English measure and more or less, moins, ayant front sur la 5ième Avenue, bornée en front par fronting on 5th Avenue, bounded in front by 5th Avenue and la 5ième Avenue et en arrière par le résidu dudit lot.in the rear by the remainder of said lot.Prior Land and Housing, 235 Melohe, Ville St-Laurent.179-P-166 nri^fnlir»dn,,1™/Ub) Of a part of lot number one hundred and sixteen of the official subdivision of original lot number one hundred and twenty-nine (129 Pt.116) on said official plan and in said book of reference, of irregular shape and bounded on the north by the remainder of said lot number 129-116, on the east by Duhamel Boulevard, on the south by that part of lot number 129-115 hereinafter described, on the west by the Ottawa River, measuring on its north and south lines ninety-three and three tenths feet (93.3') on its east and west lines four feet (4') and covering a total area of three hundred seventy-three square feet (373'), English measure and more or less.With a cottage erected thereon, bearing number 616 Duhamel Boulevard, Pincourt.Ile Perrot, and with whole content.131-P-4.An emplacement with a house and dependencies erected thereon, located in the Town of Pincourt.County of Vaudreuil, known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, under number four of the official subdivision of lot number one hundred and thirty-one (131-4) as shown on the subdivision plan prepared by W.E.Lauriault, land-surveyor, on November twelfth, one thousand nine hundred and forty-seven.Less and to withdraw from this number that part that has already been sold by Emilien Brière to Lionel Beaulieu, in a sale executed before L.J.Boileau.notary, on May twenty-ninth, one thousand nine hundred and forty-eight, and registered in Vaudreuil under number 63916.Maheu, Gaétan, 565, boulevard Duhamel, Pincourt.131-9.Russell, Marois, 1966, Prospect, Sherbrooke.137-35, 139-51.VolmerB.Wiesturs & Briedis, Diana Valda, 404, boulevard Duhamel, Pincourt.147-38.Bellevue Estates Medal Realties, 6999, Côte-des-Neiges, Montréal.152-71, 167-51.Langevin, Dame Marie, 186, Place Lilas, Pincourt.168-433.Laflèche, Dame J.Serre, 3265, Beauséjour, St-Laurent.P-177. 5636 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.Cadastre Name and address Un terrain vacant situé en la ville de Pincourt, dans le comté de Vaudreuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, comme étant composé: 1.D'une partie du lot originaire No cent soixante-dix-sept (P.177) au cadastre susdit: Mesurant en front, dans sa ligne ouest quatre-vingt-dix-huit pieds et huit centièmes de pied (98.08') en arrière dans sa ligne nord-est, quatre-vingt-neuf pieds et trente-cinq centièmes de pied (89.35') d'un côté dans sa ligne nord-ouest, cent soixante-dix-sept pieds et soixante-trois centièmes de pied (177.63') et de l'autre côté dans sa ligne sud-est deux cent vingt-trois pieds et vingt-huit centièmes de pied (223.28').contenant en superficie dix-sept mille huit cent treize pieds carrés (17,813 p.c).Mesure anglaise et plus ou moins: Borné en front à l'ouest par le chemin public (Boulevard Duhamel) en arrière au nord-est et d'un côté au nord-ouest par autre partie du même lot originaire No 177, propriété des vendeurs et de l'acquéreur et de l'autre côté au sud-est par une autre partie du lot originaire No 177 vendue ce jour à Jean-Paul Laflèche.aux termes d'un acte de vente passé devant le notaire soussigné, sous le No 2462 de ses minutes; 2.D'une autre partie du lot originaire No cent soixante-dix-sept (P.177) au cadastre susdit: Mesurant environ quatre-vingt-dix-huit pieds et huit centièmes de pied (98.08') de largeur comprise entre le chemin public (Boulevard Duhamel) et la Rivière Ottawa, mesure anglaise et plus ou moins; Borné en front par le chemin public (Boulevard Duhamel), en arrière par la Rivière Ottawa, d'un côté par autre partie du lot originaire No 177 propriété de Monsieur Jean-Paul Laflèche, et de l'autre côté par autre partie du lot originaire No 177.demeurant la propriété des vendeurs et de l'acquéreur; Pour localiser cet emplacement, sa ligne nord-ouest est le prolongement en ligne droite de la ligne nord-ouest de la partie du lot originaire No 177 ci-dessus décrite au paragraphe 1.Ainsi que le tout se trouve présentement, la grange empiétant sur ledit terrain demeurant la propriété conjointe des vendeurs et de l'acquéreur.Laflèche, Jean-Paul, 197, boulevard Duhamel, Pincourt.Un emplacement situé en la ville de Pincourt, dans le comté de Vaudreuil, connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot comme étant une partie du lot originaire No cent soixante-dix-sept (P.177).Le tout tel qu'indiqué par les lettres «ABC D A » sur un plan préparé par Jacques Demers, arpenteur-géomètre, en date du vingt et un mai mil neuf cent soixante-cinq (1965) portant le numéro D-806, lequel plan demeure annexé à un acte de déclaration de décès et de transmission passé devant le notaire soussigné, le quatorze juin mil neuf cent soixante-six (1966) sous le numéro 2439 des minutes dudit notaire.Bornéen front, parle chemin public (Boulevard Duhamel), en arrière, par les lots numéros 177-214, 216, 217, 218, 219 et 220 d'un côté, par un chemin public (lot 177-166 - 8e Avenue), et de l'autre côté, en partie par une partie non subdivisée du lot originaire No 174 au cadastre susdit, et en partie par les lots numéros 174-165,166,167,168,169.170,171 et 172 au cadastre susdit.Cet emplacement peut être plus amplement décrit comme suit: « Partant du point « A » situé à l'intersection de l'emprise sud-est de la rue 177-166 (8e Avenue) avec l'emprise est du chemin public (Boulevard Duhamel); De ce point « A » dans une direction nord-est le long de l'emprise sud-est de la rue 177-166 (8e Avenue), une distance de quatre cents pieds (400') jusqu'au point « B «qui est le coin nord-ouest du lot 177-214.De ce point « B » dans une direction sud-est le long des côtés sud-ouest des lots numéros 177-214, 216, 217, 218 et 220, une distance de quatre cent dix-sept pieds (417') jusqu'au point « C » qui est le centre du fossé de ligne séparant les lots originaires numéros 177 et 177.A piece of vacant land situated in the Town of Pincourt, in the County of Vaudreuil, known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, made up as follows : (1) a part of original lot No.one hundred and seventy-seven (Pt.177) on the aforesaid cadastre: Measuring in front, on its west line, ninety-eight and eight hundredths feet (98.08') in the rear on its northeast line, eighty-nine and thirty-five hundredths feet (89.35') on one side on its northwest line, one hundred and seventy-seven and sixty-three hundredths feet (177.63') and on the other side on its southeast line two hundred and twenty-three and twenty-eight hundredths feet (223.28'), covering an area of seventeen thousand eight hundred and thirteen square feet (17,813 sq.ft.) English measure and more or less: Bounded in front on the west by a public road (Duhamel Boulevard) in the rear on the northeast and on one side on the northwest by another part of said original lot No.177, property of the vendors and the purchaser and on the other side on the southeast by another part of original lot No.177 sold today to Jean-Paul Laflèche, in accordance with a deed of sale executed before the undersigned notary, under number 2462 of his records; (2) Of another part of original lot one hundred and seventy-seven (Pt.177) on the aforesaid cadastre: measuring about ninety-eight and eight hundredths feet (98.08') in width comprised between the public road (Duhamel Boulevard) and the Ottawa River, English measure, and more or less; bounded in front by the public road (Duhamel Boulevard), in the rear by the Ottawa River, on one side by another part of original lot No.177 belonging to Mr.Jean-Paul Laflèche, and on the other side by another part of original lot No.177, remaining the property of the vendors and the purchaser; to locate said emplacement, its northwest line is the extension in a straight line of the northwest line of that part of original lot No.177 hereinabove described in paragraph 1.As the whole now subsists, the barn encroaching upon said piece of land remaining the joint property of the vendors and the purchaser .P-177.An emplacement located in the Town of Pincourt, in the County of Vaudreuil, known and described on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, as being a part of original lot No.one hundred and seventy-seven (Pt.177).The whole as shown by letters \"A B C D A\" on a plan prepared by Jacques Demers, land-surveyor, on the twenty-first of May one thousand nine hundred and sixty-five (1965).bearing number D-806, which plan is attached to a deed of declaration of death and transfer executed before the undersigned notary, on the fourteenth of June, one thousand nine hundred and sixty-six (1966) under number 2349 of the minutes of said notary.Bounded in front by the public road (Duhamel Boulevard), in the rear by lots numbers 177-214.216.217, 218, 219 and 220 on one side, by a public road (lot 177-166-8th Avenue), and# on the other side, partly by a non subdivided part of original lot No.174 on the aforesaid cadastre, and partly by lots numbers 174-165, 166, 167.168, 169 170, 171 and 172 on the aforesaid cadastre.This emplacement can be more fully described as follows: \"Starting from point \"A\" located at the intersection of the southeast right-of-way of street 177-166 (8th Avenue) with the east right-of-way of the public road (Duhamel Boulevard) ; from this point \"A\" in a northeasterly direction along the southeast right-of-way of street 177-166 (8th Avenue), a distance of four hundred feet (400') up to point \"B\", which is the northwest corner of lot 177-214.From this point \"B\" in a southeasterly direction along the southwest sides of lots numbers 177-214,216, 217, 218 and 220, a distance of four hundred and seventeen feet (417') up to point \"C\", which is the centre of the line ditch separating original lots 177 and 177.Nom et adresse GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 82 5637 Nom et adresse Cadastre Name and addreet De ce point « C » dans une direction générale sud-ouest en suivant le centre dudit fossé de ligne une distance de deux cent dix-neuf pieds et six dixièmes de pied (219.6') jusqu'à un angle, cent soixante-dix-sept pieds et un dixième de pied (177.1') jusqu'à un second angle, soixante-deux pieds et huit dixièmes de pied (62.8') jusqu 'à un troisième angle, cent treize pieds et sept dixièmes de pied (113.7') jusqu'au point « D » situé sur l'emprise est du chemin public (Boulevard Duhamel).De ce point « D » en suivant l'emprise est dudit chemin public dans une direction générale nord une distance de trente-quatre pieds et deux dixièmes de pied (34.2') jusqu'à un angle, cinquante-trois pieds et un dixième de pied (53.1 ) jusqu'à un deuxième angle, quarante-neuf pieds (49') jusqu'à un troisième angle, soixante-seize pieds et deux dixièmes de pied (76.2') jusqu'à un quatrième angle, cent cinquante-quatre pieds et neuf dixièmes de pied (154.9') jusqu'à un cinquième angle, quarante et un pieds et deux dixièmes de pied (41.2') jusqu'à un sixième angle, cinquante pieds et trois dixièmes de pied (50.3') jusqu'au point de départ « A ».Cette partie dudit lot originaire No cent soixante-dix-sept (P.177) au cadastre susdit, de figure irrégulière, contient une superficie de deux cent trois mille dix-sept pieds carrés (203,017 p.c), soit quatre acres et soixante-six centièmes d'acre (4.66) ou cinq arpents carrés et cinquante-deux centièmes d'arpent carré (5.52 arp.c.) le tout mesure anglaise, plus ou moins.A distraire appert à actes enregistrés sous les Nos 105456, 105458, 105459, 124066 et les subdivisions 177-668, 675, 676, 677, 678.Laflèche, Jean-Paul, 197, boulevard Duhamel, Pincourt.Une partie du lot No cent soixante-dix-sept (P.177) au cadastre susdit mesurant environ quatre cent trente-cinq pieds (435' de largeur sur toute la profondeur comprise entre le chemin public (Boulevard Duhamel) et la Rivière Ottawa, soit environ quarante pieds (40') et bornée en front au nord-est par le chemin public (Boulevard Duhamel) en arrière au sud-ouest par la Rivière Ottawa, d'un côté au nord-ouest par partie du lot originaire No 178 du même cadastre et de l'autre côté au sud-est par autre partie du lot No 177 au cadastre susdit.A distraire appert à actes enregistrés sous les Nos 105468, 105459.Dagenais, Dame Pauline, 140, boulevard Duhamel, Pincourt.Un emplacement ayant front sur le Boulevard Duhamel, en la Ville de Pintcourt, à l'Ile Perrot, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro cent soixante-dix-huit (Pt.178) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, mesurant cent pieds de largeur à compter de l'emplacement appartenant à Armand Leblanc ou représentants, en se dirigeant vers l'est, le long dudit Boulevard Duhamel, par toute la profondeur entre ledit Boulevard Duhamel et la Rivière Outaouais, et borné au nord par ledit Boulevard Duhamel, au sud, par la Rivière Outaouais, à l'ouest, par la partie dudit lot appartenant à Armand Leblanc ou représentants et à l'est, par une autre partie dudit lot numéro cent soixante-dix-huit ; tous auxdits plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de 1 De Perrot.Toutes les mesures ci-dessus étant mesure anglaise et plus ou moins.Avec toutes les bâtisses y dessus érigées et notamment la maison portant le numéro 140 dudit Boulevard Duhamel, en la ville de Pincourt.From this point \"C\" in a general southwesterly line along the centre of said line ditch a distance of two hundred and nineteen and six tenths feet (219.6').up to an angle, one hundred and seventy-seven and one tenth feet (177.1') up to a second angle, sixty-two and eight tenths feet (62.8') up to a third angle, one hundred and thirteen and seven tenths feet (113.7') up to point \"D\" located on the east right-of-way of the public road (Duhamel Boulevard).From this point \"D\" along the east right-of-way of said public road in a general northerly direction over a distance of thirty-four and two tenths feet (34.2') to an angle, fifty-three and one tenth feet (53.1') to a second angle, forty-nine feet (49') up to a third angle, seventy-six and two tenths feet (76.2') up to a fourth angle, one hundred and fifty-four and nine tenths feet (154.9') to a fifth angle, forty-one and two tenths feet (41.2') to a sixth angle, fifty and three tenths feet (50.3') to starting point \"A\".This part of said original lot number one hundred and seventy-seven (Pt.177) on the aforesaid cadastre, of irregular configuration, contains two hundred and three thousand seventeen square feet (203,017 sq.ft.), that is, four and sixty-six hundredths acres (4.66 a.) or five and fifty-two hundredths square arpents (5.52 sq.arp.), the whole in English measure, more or less.To withdraw as appears from deeds registered under Nos.105456, 105458, 105459, 124066 and subdivisions 177-668.675, 676, 677 and 678.P-177.A part of lot No.one hundred and seventy-seven (Pt.177) on the aforesaid cadastre measuring approximately four hundred thirty-five feet (435') in width by all the depth comprised between the public road (Duhamel Boulevard) and the Ottawa River, that is, approximately forty feet (40'), and bounded in front on the northeast by-the public road (Duhamel Boulevard), in the rear on the southwest by the Ottawa River, on one side on the northwest by part of original lot number 178 on said cadastre and on the other side on the southeast by another part of lot No.177 on the aforesaid cadastre.To withdraw as appears from deeds registered under Nos.105458, 105459.P-178.An emplacement fronting on Duhamel Boulevard, in the Town of Pincourt, on He Perrot, known and described as being a part of lot number one hundred and seventy-eight (Pt.178) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, measuring one hundred feet in width measured from the emplacement belonging to Armand Leblanc or representatives, in an easterly direction, along said Duhamel Boulevard, by all the depth comprised between said Duhamel Boulevard and the Ottawa River, and bounded on the north by said Duhamel Boulevard, on the south, by the Ottawa River, on the west, by part of said lot belonging to Armand Leblanc or representatives and on the east, by another part of said lot number one hundred and seventy-eight; all on said official plan and in said book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot.All the above measurements being in English measure and more or less.With all buildings erected thereon and particularly the house bearing number 140 of said Duhamel Boulevard, in the Town of Pincourt.178-333-26.178-333-41.178-333-49.179-68.179-132.179-P-151.P-180.Daencarnacao, Antonio, 119, Strachan, Toronto, Ontario.Bellantoni, Leonardo, 96, All ice, Guelph, Ontario.Novelo, Michèle et al, 228, Markham, Toronto, Ontario.Murphy, Claude, 133.Sième Avenue, Pincourt.Bouchard, Mile-Miss Diana.1776, Ernest Lapointe, Apt.8-1, Québec.Bellevue Estates Ltd., 6999, Côte-des-Neiges, Montréal.Prior Land and Housing & Productive Land Investments, 235, Meloche, Ville St-Laurent. 5638_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol- 106, No.32__ Qu'un certain emplacement vacant frontant sur le Boulevard Cardinal Léger, et le Boulevard Duhamel, dans la ville de Pincourt, Province de Québec, de figure irrégulière étant une partie du lot No cent quatre-vingt (P.180) aux plan officiel et livre de renvoi de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, étant plus complètement décrits et indiqués par les lettres «ABCDEFGHJKLMA».Ce morceau de terrain est décrit comme suit: Commençant au point « A \u2022 étant le point d'intersection du côté sud-ouest du Boulevard Cardinal-Léger avec une ligne de division entre ledit lot 180 et le lot 179-229 et continuant dans une direction sud-ouest une distance de mille sept cent quatre pieds et neuf dixièmes de pied (1704.9') jusqu'au point « B » étant le point d'intersection avec la ligne nord-est du boulevard Duhamel; à partir du point « B » allant le long de la ligne de division entre le lot 180 et le Boulevard Duhamel dans une direction nord-ouest une distance de vingt et un pieds et quatre-vingt-douze centièmes de pied (21.92') jusqu'au point « C ».à partir du point « C », allant dans une direction nord le long de la ligne de division entre le lot 180 et le Boulevard Duhamel une distance de deux cent soixante-dix-neuf pieds et vingt-trois centièmes de pied (279.23') jusqu'au point « E »; à partir du point « E » allant le long de la ligne de division entre le lot 180 et le Boulevard Duhamel dans une direction nord une distance de cent quatorze pieds et dix-huit centièmes de pied (114.18') jusqu'au point « F »; à partir du point « F » allant dans une direction nord le long de ladite ligne de division une distance de soixante-huit pieds et quatre-vingt-quinze centièmes de pied (68.95').jusqu'au point « G »; à partir du point « G \u2022 allant dans une direction sud-est le long de la ligne de division entre le lot 180 et le lot 180-149 (rue) une distance de deux cent dix pieds (210') jusqu'au point ¦ H » à partir du point « H » et allant dans une direction est une distance de soixante-huit pieds et trois centièmes de pied (68.03') le long de la ligne de division entre le lot 180 et le lot 180-166 (rue) jusqu'au point ¦ J »; à partir du point ¦ J » continuant le long de la ligne de division entre ladite partie du lot 180 et le lot 180-209 et partie du lot 180 (rue) une distance de mille quatre-vingt-quatorze (1,094) dans une direction nord-est jusqu'au point « K »; à partir du point « K » allant le long de la ligne de division entre ladite partie du lot 180 et le lot 180-252 acheté par Texaco et partie du lot 180 occupée par Texaco dans une direction sud-est une distance de deux cent cinquante-huit pieds et soixante-quinze centièmes de pied (258.75') jusqu au point « L «; à partir du point >Li allant dans une direction nord-est le long de la ligne de division entre ladite partie du lot 180 et partie 180 occupée présentement par Texaco une distance de cent vingt et un pieds et dix-huit centièmes de pied (121.18') jusqu'au point « M » étant le point d'intersection avec le Boulevard Cardinal Léger; à partir du point ¦ M » allant le long de la ligne de division entre ladite partie du lot 180 et le côté sud-ouest du Boulevard Cardinal-Léger dans une direction sud-est une distance de cent soixante-six pieds et vingt et un centièmes de pied (166.21') jusqu'au point de départ \u2022 A ».Contenant ladite partie une superficie de six cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-neuf pieds carrés (683,669 p.c.) mesure anglaise équivalant à dix-huit arpents carrés et cinquante-sept centièmes d'arpent (18.57 a.c.) mesure française).A distraire de cette partie dudit lot cent quatre-vingt (P.180) les parties vendues par Productive Land Investment Ltd.suivant actes enregistrés à Vaudreuil soUB les numéros 114913.114914, 114916 et 116507.That certain vacant emplacement fronting on Cardinal-Léger Boulevard and Duhamel Boulevard, in the Town of Pincourt, Province of Québec, of irregular configuration, being a part of lot No.one hundred andeighty (Pt.180) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, more fully described and indicated by the letters \"A B C D E F G H J K L M and A\".Said piece of land is described as follows: Starting at point \"A\", which is the point of intersection of the southwest side of Cardinal-Léger Boulevard, with a dividing line between said lot 180 and lot 179-229 and proceeding in a southwesterly direction over a distance of one thousand seven hundred and four and nine tenths feet (1.704.9') to point \"B\", which is the point of intersection with the northeast line of Duhamel Boulevard; starting from point \"B\" proceeding along the dividing line between lot 180 and Duhamel Boulevard in s northwesterly direction over a distance of twenty-one and ninety-two hundredths feet (21.92') to point \"C\", starting from point \"C\", proceeding in a northerly direction along the dividing Une between lot 180 and Duhamel Boulevard over a distance of two hundred and seventy-nine and twenty-three hundredths feet (279.23') up to a point \"E\"; starting from point \"E\" along the dividingline between lot 180 and Duhamel Boulevard in a northerly direction over a distance of one hundred and fourteen and eighteen hundredths feet (114.18') to point \"F\"; starting from point \"F\" proceeding in a northerly direction along said di\\ ioing line over a distance of sixty-eight and ninety-five hundredths feet (68.96'), to point \"G\"; starling from point \"G\" proceeding in a southeasterly direction along the dividingline between lot 180 and lot 180-149 (street) a distance of two hundred and ten feet (210') to point \"H\"; startingfrom point \"H\" and proceeding in an easterly direction over a distance of sixty-eight and three hundredths feet (68.03') along the dividingline between lot 180 and lot 180-166 (street) to point \"J\"; starting from point \"J\" proceeding along the dividing line between said part of lot 180 and lot 180-209 and part of ot 180 (street) a distance of one thousand ninety-four feet (1.094') in a northeasterly direction to point \"K\"; starting from point \"K\" proceeding along said dividing line between said part of lot 180 and lot 180-252 purchased by Texaco and part of lot 180 occupied by Texaco in a southeasterly direction over a distance of two hundred and fifty-eight and seventy-five hundredths feet (258.75') to point \"L\"; startingfrom point \"L\" proceeding in a northeasterly direction along said dividing line between said part of lot 180 and part 180 presently occupied by Texaco, over a distance of one hundred and twenty-one and eighteen hundredths feet (121.18') to point\" M\" which is the point of intersection with Cardinal-Léger Boulevard; starting from point \"M\" proceeding along the dividing line between said part of lot 180 and the southwest side of Cardinal-Léger Boulevard in a southeasterly direction over a distance of one hundred and sixty-six and twenty-one hundredths feet (166.21') to starting point \"A\".Said part containing six hundred and eighty-three thousand six hundred and sixty-nine square feet (683,669 sq.ft.) English measure equivalent to eighteen and fifty-seven hundredths square arpents (18.57 sq.ar.), French measure.To withdraw from this part of said lot one hundred and eighty (Pt.180), those parts sold by Productive Land Investment Ltd., according to the deeds registered in Vaudreuil under numbers 114913, 114914, 114915 and 115507.Prior Land and Housing, 235, Meloche, Ville St-Laurent.Parolin, Ugo.1423, Duflerin Street, Toronto, Ontario.Partie du lot originaire numéro cent trente-six (P.136) aux plan officiel et livre de renvoi de la paroisse de Ste-Jeanne de 1 lie Perrot.borné au nord-est par partie du lot No 136 boulevard Cardinal-Léger au sud-est par partie du lot No 135.au sud-ouest et nord-ouest par partie du lot No 136, mesurant 60 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest et 120 pieds dans .180-151.P-136.Part of the original lot number one hundred and thirty-six (Pt.136) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne on He Perrot.bounded on the northeast by part of lot No.136.Cardinal-Léger Boulevard, on the southeast by part of lot No.135.on the southwest and on the northwest by part of lot No.136, measuring 60 feet on its Nom et adresse Cadastre Name and address GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n°-3S 5639 ses lignes sud-est et nord-ouest, contenant une superficie totale northeast and southwest lines and 120 feet on its southeast de 6,954 pieds carrés.and northwest lines, covering a total area of 6,954 square feet.Barbieri, Nicola, 165 Princess Ann Crescent, Toronto, Ontario Cinq emplacements situés dans la ville de Pincourt connus et désignés comme étant parties du lots originaire No cent trente (P.130) aux plan officiel et livre de renvoi de la paroisse Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, mesurant et bornés comme suit: Lesdits lots mesurant ensemble deux cents pieds et quatre centièmes de pied (200.04') dans sa direction nord-sud, par cent soixante pieds (160') plus ou moins, dans sa direction est-ouest Lesdits lots étant bornés comme suit: en front vers l'ouest par un boulevard (P.130), vers le nord et vers le sud par deux rues et en arrière vers l'ouest par une autre partie dudit lot originaire No 130 dudit cadastre.Thémens, Emile, Adresse inconnue-Unknown address.Un emplacement situé à Pincourt, dans le comté de Vaudreuil, prcviice de Québec et connu et désigné comme étant une par' is du lot ninuro cent trente-quatre (Ptie 134) aux plan et li vre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Jeanne de l'Ile Perrot dans le comté de Vaudreuil, mesurant ladite partie environ deux cents pieds (200') de largeur dans sa ligne sud ouest pour une profondeur de soixante pieds (60') à être mesurée dans la direction nord-est et de là mesurant une largeur d'environ cent dix pieds (110') pour une profondeur additionnelle à être mesurée dans la même direction nord-est de soixante-dix pieds (70') et bornée ladite partie au sud-ouest par Stella Drainville, au nord-est par Messieurs Emile Thémens et Ro-bidoux ou représentants, au nord-ouest par la ligne sud-est de l'emplacement de Monsieur Roy ou représentants et par ledit Emile Thémens et au sud-est par Monsieur Diotte ou représentants.A distraire cependant dudit emplacement la partie vendue à Jean-Paul RobitaUle, suivant acte enregistré à Vaudreuil, sous le No 78915: Un emplacement étant une partie du lot numéro cent trente-quatre (Ptie 134) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, comté de Vaudreuil, emplacement de forme irrégulière et mesurant dans sa ligne sud-est vingt-cinq pieds (25') dans sa ligne sud-ouest soixante-quatorze pieds (740.dans sa ligne nord soixante-quinze pieds et cinq dixièmes de pieds (75.5'), dans une ligne nord-est cinq pieds (5') et dans les deux autres lignes nord-ouest et sud-ouest cinquante-cinq pieds (55') chacune et bornée ladite partie: dans sa ligne sud-est par une partie du lot numéro 131 appartenant au présent cessionnaire.d'un côté au sud-ouest mesurant soixante-quatorze pieds (74'), du côté nord mesurant soixante-quinze pieds et cinq dixièmes de pied (75.'5) et du côté sud-ouest mesurant cinq pieds (5') par d'autres parties dudit lot numéro 134 et pour les deux autres lignes nord-ouest et sud-ouest mesurant cinquante-cinq pieds (55') chacunepar une autre partie du lot numéro 134 appartenant au cessionnaire.Cette partie cependant parait avoir été erronément désignée dans le plan qui est annexé aux présentes comme étant une partie du lot numéro cent trente.Le tout tel que mentionné en un plan préparé par Philippe Bernier, arpenteur-géomètre en date du dixième jour de septembre mil neuf cent cinquante-neuf et liséré en bleu sur ledit plan lequel demeurera annexé aux présentes après avoir été reconnu véritable et signé pour identification par les parties aux présentes en présence du notaire soussigné.P-130.Five emplacements located in the Town of Pincourt.knowi.and described as being parts of original lot number one hundred and thirty (Pt.130) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne on He Perrot, measuring and bounded as follows: Said lots measuring together two hundred and four hundredths feet (200.04') on its north-south direction, by one hundred and sixty feet (160'), more or less, on its east-west direction.Said lots being bounded as follows: in front on the west by a boulevard (Pt.130).towards the north and the south by two streets, and in the rear towards the west by another part of said original lot No.130 on said cadastre.P-130.P-134.An emplacement located in Pincourt, in the County of Vaudreuil, Province of Québec and known and described as being a part of lot number one hundred and thirty-four (Pt.134) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot in the County of Vaudreuil, said part measuring about two hundred feet (200') in width on its southwest line by a depth of sixty feet (60') to be measured in a northeasterly direction and from there, measuring about one hundred and ten feet (110') in width for an additional depth of seventy feet (70') to be measured in the same northeasterly direction, said part being bounded on the southwest by the property of Stella Drainville, on the northeast by the property of Messrs.Emile Thémens and Robidoux or representatives, on the northwest by the southeast line of the emplacement belonging to Mr.Roy or representatives and by the property of the said Emile Thémens and on the southeast by the property of Mr Diotte or representatives.Less and to withdraw, however from said emplacement that part sold to Jean-Paul Robitaille, under the terms of a deed registered at Vaudreuil, under number 78915; an emplacement being part of a lot number one hundred thirty-four (Pt.134) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste-Jeanne de l'Ile Perrot, County of Vaudreuil, emplacement of irregular configuration and measuring on its southeast line twenty-five feet (25'!, on its southwest line seventy-four feet (74'), on its north line seventy-five and five tenths feet (75.5'), on a northeast line five feet (5'), and on the other two northwest and southwest lines fifty-five feet (55') each and bounded by said part: on its southeast line by a part of lot number 131 belonging to I h ; present transferee, on one side on the southwest measuring seventy-four feet (74'), on the north side measuring seventy-five and five tenths feet (75.5') and on ths southwest side measuring five feet (5'), by other parts of said lot number 134 and for other two northwest and southwest lines measuring fifty-five feet (55') each, by another part of lot number 134 belonging to the transferee.This part however seems to have been wrongly designated on the plan attached hereto as being part of lot number one hundred and thirty.The whole as mentioned in a plan prepared by Philippe Bernier, land-surveyor and dated the tenth day of September of the year one thousand nine hundred and fifty-nine and outlined in blue on said plan which will remain annexed to these presents after having been certified and signed for identification purposes by the parties hereto, in the presence of the undersigned notary.Donné à Pincourt, le 25e jour de juillet 1974.Given at Pincourt, this 25th day of July 1974.Le secrétaire-trésorier, Guy-A.Paquette, 58057-31-2-o Guy-A.Paquette.58057-31-2 Secretary-Treasurer.Nom et adresse Cadastre Name and address 5640 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.33 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.Ill \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).rV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.- transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en \\rac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5641 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux» les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes M ont real Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 à M 002000 Q 000001 à Q 001000 M 100001 à M 103000 Q 100001 à Q 102000 M 200001 à M 210000 Q 200001 à Q 205000 M 300001 à M 303000 Q 300001 à Q 302000 M 400001 à M 402000 Q 400001 à Q 401000 M 500001 à M 504000 Q 500001 à Q 503000 M 600001 à M 601000 Q 600001 à Q 600500 M 700001 à M 700500 Q 700001 à Q 700500 M 800001 à M 800500 Q 800001 à Q 800500 M 900001 à M 900500 Q 900001 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal publie transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking 5642 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Quebec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Quebec specialized transportation \u2014 rail II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.Role Q-1534 34-DYA D-l CHICOUTIMI DRIVE YOURSELF REG'D (Pierre Ouellet opérant sous le nom/operating under the name:) 23, ouest rue Jacques-Cartier Chicoutimi (Que.) Rôle Q-1538 Q-24,011 D-l MONSIEUR GASTON GRENIER 160, 32ème Rue St-Georges Ouest, Cté Beauce G5Y 4G7 Rôle Q-1544 745-V-D-l FERLAND, PACIFIQUE 4540, boulevard Hamel, Ancienne-Lorette Comté Chauveau, P.Q.Québec.Rôle Q-1545 23862-V-D-l LEVESQUE, EDGAR Maria Comté Bonaventure (Que.) et/and 21839-V BOURQUE, ÉRIC J.CP.96 Maria Cté Bonaventure (Que.) Nouvelle demande: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec, de l'autoriser à donner les services de location de véhicules comme suit: Service 1 : Location à court terme (moins d'une année) d'autobus à 23 Jacques-Cartier, Chicoutimi.Service 2: Location à long terme (une année et plus) d'autobus.Les taxis de St-Georges-est et de St-Georges-ouest demandent à la Commission des transports du Québec de regrouper les municipalités de St-Georges, St-Georges-est et St-ûeorges-ouest en une seule municipalité: St-Georges.II \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.New request: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide vehicle-leasing services as follows: Service 1: Leasing of buses on a short-terra basis (less than one year) at 23 Jacques-Cartier, Chicoutimi.Service 2 : Leasing of buses on a long-term basis (one year and more).The taxicab owners of St.Georges-East and St.Georges-West request the Québec Transport Commission to regroup the Municipalities of St.Georges.St.Georges-East and St.Georges-West into one municipality : St.Georges.Modification de permis: La partie requérante demande d'ajouter à son permis de transport le service suivant: Transport de fenêtres en aluminium et accessoires s'y rattachant avec camion spécialisé, des fabriquants de Montréal à Québec et retour avec marchandise avariée ou refusée pour le compte de Aluminium Tremblay (1973) Ltée.265.Dorchester sud, Québec 2, (Que.).Nouvelle demande: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Edgar Levesque à tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Eric J.Bourque (21839-V) selon les clauses a, b.c et d dudit permis No 21839-V.Modification of permit: The applicant requests that the following service be added to its transport permit : Transport of aluminum windows and parts related thereto, by special truck, from the premises of manufacturers in Montreal, to Québec City, and return with damaged or refused goods, on behalf of Aluminium Tremblay (1973) Ltée, 265 Dorchester South, Québec 2, P.Q.New request: Haulaway transport service - contract -Request is made to authorize Edgar Levesque to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Eric j.Bourque (21839-V) according to clauses a, b, c and d of said permit No.21839-V. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' armée, n° 32 5643 Rôle Q-1546 3652-V-D-2 TRANSPORT THÉBERGE LIMITÉE, 455 est, rue Notre-Dame CP.790 Trois-Pistoles, Cté Rivière-du-Loup GOL 4K0 Modification de permis: La partie requérante demande de modifier la clause c de son permis No 3652-V, afin qu'elle se lise à l'avenir comme suit: Transport général - longue distance -route - De Rimouski, Mont-Joli, Ste-Flavie, Price, St-Octave-de-Métis et Grand-Métis ainsi que tous les endroits situés dans le district électoral provincial de Rimouski à Trois-Pistoles, Québec et Montréal, et retour.Droits additionnels: 1.La détentrice est autorisée à utiliser les routes 10, 2 et alternativement les routes 6, 132, 2 et 20.2.La détentrice est autorisée à utiliser les camions climatisés (isothermes).3.La détentrice est autorisée à faire la livraison de bois préparé dans un rayon de 75 milles de Québec et dans un rayon de 100 milles de Montréal.Modification of permit: The applicant requests that clause c of its permit No.3652-V be modified to read as follows in the future: General trucking - long distance - route - From Rimouski, Mont-Joli, Ste.Flavie, Price, St.Octave-de-Métis and Grand-Métis as well as all the points located in the Provincial Electoral District of Rimouski.to Trois-Pistoles, Québec City and Montreal, and return.Additional rights: 1.The permit-holder shall be authorized to use Highways 10, 2 and alternatively, Highways 6, 132, 2 and 20.2.The permit-holder shall be authorized to use air-conditioned (temperature controlled) trucks.3.The permit-holder shall be authorized to deliver dressed lumber within a radius of 75 miles from Québec City and within a radius of 100 miles from Montreal.Rôle Q-1547 10965-V-D-2 5032-V-D-l 10965-V CAYER TRANSPORT LTÉE 346 rue St-Hubert CP.1060 St-Raymond Cté Portneuf (Que.) et/and 5032-V LAURENTIDE TRANSPORT INC.10525 Côte-de-Liesse Pointe-Claire Dorval 760 (Que.) Demande de transfert partiel: Cayer Transport ltée demande l'autorisation de transférer les clauses b, c, d, e, f, g, k, l, m, n ainsi que la clause additionnelle accordée le 28 juin 1974, de son permis de transport No 10965-V, à la compagnie.Laurentide Transport Inc.(5032-V) 10525 Côte-de-Liesse Pointe-Claire Dorval 760, (Que.), les clauses susmentionnées du permis de transport No 10965-V: 6) Transport général - longue distance -rayon - b) De St-Raymond à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite municipalité, et retour.c) Transport général - iongue distance -route restreinte - c) De St-Raymond, Ste-Catherine, Fos-sambault-sur-le-Lac et Ville du Lac St-Joseph à Québec, et retour.d) Transport général - longue distance -route restreinte - irrégulier - d) De St-Raymond à Montréal, et retour.e) Transport restreint - longue distance -rayon - e) De St-Raymond à ailleurs dans un rayon de 300 milles et retour, sauf Québec et Montréal, pour le transport de chevaux et effets, pour le compte des contracteurs de bois opérant à St>Raymond./) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - X) De Scott Jonction à St-Raymond ou Pont-Rouge, pour le transport de briques pour le compte de Clément Bernard, de St-Raymond.g) Transport général - longue distance -rayon - contrat - g) De St-Raymond à ailleurs dans la province, dans un rayon de 300 milles, et retour, sauf Québec et Montréal, pour le transport de marchandises pour St-Raymond Paper Co.Ltd., et les clients de ladite compagnie.k) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - k) De Pont-Rouge à ailleurs dans la province, pour le transport de portes de veneer non emballées, pour le compte de Portneuf Plywood Inc.Request for partial transfer: Cayer Transport ltée requests authorization to transfer clauses b, c, d, e, f, g, k, I, m, n of its transport permit No.10965-V as well as the additional clause granted on June 28, 1974,to: Laurentide Transport Inc.(5032-V) 10525 Côte-de-Liesse Pointe-Claire Dorval 760, P.Q.The aforementioned clauses of transport permit No.10965-V: (6) General trucking - long distance -radius - (b) From St-Raymond to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said Municipality, and return.(c) General trucking - long distance - restricted route - (c) Frqm St.Raymond, Ste.Catherine, Fossambault-eur-le-Lac and the Town of Lac St.Joseph to Québec City, and return.(d) General trucking - long distance - restricted route - irregular - (d) From St.Raymond to Montreal, and return.(e) Restricted trucking - long distance -radius - (e) From St.Raymond to other points within a radius of 300 miles, except Québec City and Montreal, and return, for the transport of horses and goods, on behalf of lumbering contractors operating in St.Raymond.Of) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (/) From Scott-Jonction to St.Raymond or Pont-Rouge, for the transport of bricks on behalf of Clément Bernard, of St.Raymond.(g) General trucking - long distance - radius - contract - (g) From St.Raymond to other points in the Province, within a radius of 300 miles, except Québec City and Montreal, and return, for the transport of goods on behalf of St.Raymond Paper Co.Ltd., and the clients of said company.(k) Restricted trucking - long distance -radius - contract - (fc) From Pont-Rouge to other points in the Province, for the transport of non-crated plywood doors, on behalf of Portneuf Plywood Inc. 5644 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Rôle Q-1548 20914-V-D-l LYONNAIS TRANSPORT ENREGISTRÉE (Jean-Claude Lyonnais), 1360 boul.Foucault, Drummond ville, Cté Drummond I) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - () De St-Raymond de Portneuf à ailleurs dans la province, et retour, pour le transport de bois préparé, pour le compte de Paul-B.Godin Inc., Clément Bernard ltée et Les Industries de Bois StrRaymond ltée.Droit additionnel: En donnant le service autorisé par les clauses c et d du permis ci-dessus, Cayer Transport ltée aura le droit de faire la cueillette et la livraison à Pont-Rouge, St-Basile et Ste-Catherine, comté de Portneuf.m) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - m) De la gare de la Cie des Chemins de fer Nationaux du Canada située à Québec à la gare de la Cie des Chemins de fer Nationaux du Canada située à St-Casimir, et retour, avec le droit de desservir les gares intermédiaires de Cap-Rouge, St-Raymond.Donnacona, Portneuf, St-Marc-des-Carriè-reset la résidence de l'agent à St-Augustin, pour le transport de marchandises pour le compte de La Cie des Chemins de fer Nationaux du Canada.Restrictions: 1.Les droits octoyés par cette clause sont limités au transport de marchandises d'une gare à l'autre et la résidence de l'agent à St-Augustin, pour le compte de La Cie des Chemins de fer Nationaux du Canada et n'autorisent aucun transbordement, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 47 de l'Ordonnance générale sur le Camionnage.2.Cette classe n'autorise pas la cueillette et la livraison des marchandises à aucun endroit en dehors des gares mentionnées et de la résidence de l'agent, nonobstant les dispositions du para 8 de l'article 47 de l'Ordonnance générale sur le Camionnage.n) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - n) De Chambly à StrRaymond, Pont-Rouge, Ste-Catherine.St-Léonard, Ste-Christine et St-Basile-de-Portneuf, pour le transport d'engrais chimiques en sacs, pour le compte de Agricultural Chemicals Lim ited.Transport rrestreint - longue distance -rayon - contrat - De St-Raymond, Comté de Portneuf à St-Jean d'Iberville, Ste-Thérèse-de-Blainville, St-Jérôme (Terrebonne), Sherbrooke, Drum-mondville et Valcour, pour le transport de palettes de bois et de bois préparé, et retour avec marchandises endommagées ou refusées, le tout pour le compte de fiourassa Industries (1973) limitée.Modification de permis: La partie requérante demande le service additonnel suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De la gare de la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada à Drummond-ville aux gares et/ou aux résidences des agents de la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada à Manseau, Vilieroy, Fortierville.St-Jacques-de-Parisville, Val-Alain, Laurier-Station et St-Apollinaire, et retour, pour le transport de marchandises, pour le compte de la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada.(I) Restricted trucking - long distance -radius - contract - ,___, (l) From St.Raymond (Portneuf) to other points in the Province, and return, for the transport of dressed lumber, on behalf of Paul-B.Godin Inc.Clément Bernard ltée and Les Industries de Bois St-Raymond ltée.Additional right: When providing the service authorized by clauses c and d of the above-mentioned permit, Cayer Transport ltée shall have the right to pick-up and deliver goods in Pont-Rouge, St.Basile and Ste.Catherine, County of Portneuf.(m) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (m) From the Canadian National Railways Company station located in Québec City to the Canadian National Railways Company station in St.Casimir, and return, with the right to serve the intermediate stations of Cap-Rouge, St-Raymond, Donnacona, Portneuf, St-Marc-des-Carrières and the residence of the agent in St-Augustin, for the transport of goods on behalf of The Canadian National Railways Company.Restrictions : 1.The rights granted by this clause are restricted to the transport of goods from one station to another or to or from the residence of the agent in St-Augustin, on behalf of The Canadian National Railways Company; they do not authorize any transhipment, notwithstanding the provisions of paragraph 3 of article 47 of the General Order on Trucking.2.This clause does not permit the pick-up and delivery of goods at any point other than the above-mentioned stations and the agent's residence, notwithstanding the provisions of paragraph 8 of article 47 of the General Order on Trucking.(n) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (n) From Chambly to St-Raymond, Pont-Rouge, Ste-Catherine, St-Léonard, Ste-Christine and St-Basile-de-Portneuf, for the transport of chemical fertilizers in bags, on behalf of Agricultural Chemicals Limited.Restricted trucking - long distance - radius - contract - From St-Raymond, County of Portneuf to St-Jean (Iberville), Ste-Thérèse-de-Blain-ville, St-Jérôme (Terrebonne), oncruiuoite, Drummondville and Valcour, for the transport of woodenpallets and dressed lumber, and return with damaged or refused goods, the whole on behalf of Bourassa Industries (1973) limitée.Modification of permit: The applicant requests the following additional service: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - From the Canadian National Railways station in Drummondville to the stations and/or residences of Canadian National Railways agents in Manseau, Vilieroy, Fortierville, St-Jacques-de-Parisville, Val-Alain, Laurier-Station and St-Apollinaire, and return, for the transport of goods, on behalf of the Canadian National Railways Company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 82 5645 Rôle Q-1549 5571-V-D-l FERNAND CRÊPEAU Ste-Brigitte-des-Saults Cté Nicolet et / and 69-V BOURRET TRANSPORT LTÉE Boni.St-Joseph, R.R.No 4 Grantham-Ouest (Drummondville) Cté Drummond Rôle Q-1550 16645-V-D-l J.J.R1VERIN (décédé / deceased) Chemin Rivière Deschênes CP.160, Arvida Cté Chicoutimi et/and JUL1 ANN A PERRON RÉAL RI VERIN et / and PIERRE RIVERIN en tant qu'exécuteurs testamentaires de la succession de J.J.Riverin / in their capacity as executors, for the estate of J.J.Riverin Rôle Q-1551 634-DY & 162-DYV D-l LOCATION LAURENTIENNE INC.LAURENTIAN LEASING INC.1700, Dorchester Nord Québec, P.Q.Demande de transfert (clause d) : Femand Crépeau demande l'autorisation de transférer la clause d de son permis de transport No 5571-V à la compagnie: Bourret Transport ltée (69-V) Boul.St-Joseph, R.R.No 4 Grantham-ouest (Drummondville) Cté Drummond, laquelle se lit comme suit: d) Transport général - longue distance -route restreinte - d) De Ste-Brigitte-des-Saults, St-Cyrille et St-Charles à Québec et retour, via route régionale et route No 9.Transmission (Suite à un décès) : Les requérants, exécuteurs testamentaires, demandent le transfert du permis de Courtier portant le No 16645-V qui était au nom de Jean-Joseph Riverin, à la succession de Jean-Joseph Riverin, plus exactement aux exécuteurs testamentaires Julianna Perron, Réal Riverin et Pierre Riverin.Request for transfer (clause d) : Fernand Crépeau requests authorization to transfer clause d of its transport permit No.5571-V to: Bourret Transport ltée (69-V) St.Joseph Blvd., R.R.No.4, Grantham West (Drummondville), County of Drummond, which readsas follows: (: La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement No 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix (10) jours francs de la date de la présente publication : I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: The Commission gives notice of its intention to decide on the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation No.2.Anyone who wishes to be heard must make his intention known within a period of ten (10) clear days following the date of this publication : Rôle M-2768 23327-V P-l GAUTHIER, BERNARD 135, rue Louis-Hébert Hull, Que.Mise en cause Rôle M-2786 2047-V P DELIVRO (CANADA) INC.Rôle M-2843 21992-V P-2 ARNOLD BROS.TRANSPORT LTD.739, boul.Logimodière Winnipeg, Manitoba Au Québec / In Québec: 212, ave.Bloomfield Outremont, Que.Mise en cause.Pour décréter la révocation du permis de la partie en cause qui a cessé d'effectuer le service autorisé par son permis.Aux fins de vérifier le permis de Delivro (Canada) Inc., concernant en particulier l'utilisation du tarif 2047-TF déposé le 19 avril 1973 et approuvé par décision de la Commission des transports du Québec en date du 8 juillet 1973.Aux fins de révoquer la décision MS-844 en date du 11 juillet 1974 et de considérer à nouveau la requête de permis spécial.Cette cause sera entendue le 9 septembre 1974 à 10.00 A.M., à la Division No 2.au 800 est boul.de Maisonneuve, 7e étage, Montréal.To order the revocation of the permit held by the party to the case, which has ceased to provide the service authorized by its permit.For the purposes of verifying the permit held by Delivro (Canada) Inc., concerning particularly the use of tariff 2047-TF filed on April 19,1973.and approved by a decision of the Quebec Transport Commission on July 8, 1973.For the purposes of revoking decision MS-844 dated July 11, 1974 and of considering again the request for special permit.This cause shall be heard on September 9, 1974, at 10:00 A.M.at Division No.2, at 800 De Maisonneuve Blvd.West.7th floor, Montréal.58086-0 5656 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.August 10.1974.Vol.106.No.32 V \u2014 Avis des décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.5S du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément ii l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS No Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions QCR-694 QCR-695 QCR-696 TF QCR-697 TF QCR-698 TF QCR-699 TF QCR-702 QCR-703 QCR-704 QCR-705 QCR-706 QCR-707 25-07-74 26-07-74 26-07-74 26-07-74 26-07-74 26-07 74 29-07-74 30-07-74 30-07-74 31-07-74 31-07-74 31-07-74 Q-6793-V-D-9 BRAZEAU TRANSPORT INC.23765-V-D-l CLAUDE DENOMMEE 6579-V-D-l TF CLOUTIER.ALBERT Modification de tarifs Modification of tariffs 18430-V-D-l TF PORLIER EXPRESS INC.Modification de tarifs Modification of tariffs 21157-V-D-2 TF SEPT-ILES LABRADOR CARTAGE INC.Modification de tarifs Modification of tariffs 478-V-D-2 TF FRANÇOIS NOLIN LTEE Modification de tarifs Modification of tariffs 13605-V-D-2 MICHEL COTE Requérant-vendeur A pplicant-vendor LES DEMENAGEMENTS COTE JR.ENR.Requérant-acquéreur Applicant-purchaser 7801-V-D-l LAMPRON.GEORGE8 ETIENNE (décédé / deceased) Requérant-vendeur A pplicant-vendor MME GERMAINE HEATCOAT- LAMPRON Requérante-acquéreur Applicant-purchaser 22867-V-D-l MARC PETITPAS 8ervice additionnel Additional service 3653-V-D-2 THETFORD TRANSPORT LIMITEE Modification de clause Modification of clauses 10207-V-D-l TESSIER & FILS LIMITEE Service additionnel Additional service 18689-V-D-l HENRI GILLES BELIVEAU ENR.Service additionnel Additional service 4115 4115 3470 3348 3348 3348 3843 4124 01-06-74 01-06-74 11-05-74 04-05-74 04-05-74 04-06-74 25-05-74 01-06-74 Q-1189 Q-1188 Q-llll Q-1051 Q-1052 Q-1049 Q-1159 Q-1201 3843 1694 4128 3839 25-05-74 02-03-74 01-06-74 25-05-74 Q-l 163 Q-807 Q-1223 Q-1141 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée en partie Partly granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 38 5657 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérante\t\t\tCause\t No\tDate\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t QCS-354\t31-07-74\t13805-V-D-l\t7417\t16-12-73\tQ-453\tAccordée / Granted \t\tG.DION TRANSPORT INC.Service additionnel Additional service\t\t\t\t QCS-355\t31-07-74\tQ-23712-V-D-1\t2806\t13-04-74\tQ-974\t \t\tJIM KENNY Voiturier-remorqueur Haulaway operator 4724-V MAGNY TRANSPORT INCORPOREE Voiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t La Commission abroge la décision rendue le 3 juin 1974.QCS-356 31-07-74 The Commission repeals its decision rendered on June 3, 1974.23055-V-D-l RENE COUTURE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 13963-V SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Voiturier-roulier / Carrier 2804 13-04-74 Q-968 La Commission abroge la décision rendue le 4 juin 1974.QCS-357 TF 01-08-74 The Commission repeals its decision rendered on June 4, 1974.QCS-358 QL-167 QL-171 QPV-331 TF QPV 332 QPV-333 QCV-19 QCR-701 QCV-20 QCR-700 01-08-74 31-07-74 31-07-74 29-07-74 31-07-74 31-07-74 26-07-74 26-07-74 Q-20536-V-D-1 TF ENTREPOT ST-MALO WAREHOUSE INC.Modification de tarifs Modification of tariffs 22837-V-D-l RAYMOND CARON Voiturier-remorqueur Haulaway operator 4561-V CABANO TRANSPORT LTEE Voiturier-roulier / Carrier 1299-DY D-l VULCANISATION DUBE & OUELLET LIMITEE Service additionnel Additional service 32-DY-D-l CANAMERICAN AUTO LEASE AND RENTAL LTD.Requérante- venderesse A pplicant-vendor 657-DY LAURENTIDE AUTOMOBILES (1973) INC.Requérante-acquéreur A pplicant-purchaser 3004-A-D-l TF AUTOBUS TRANSPORT R.PELLETIER 4 FILS ENRG.Modification de tarifs Modification of tariffs 2755-A-D-l TAXI GAGNON (1966) INC.Service additionnel Additional service 3417-A-D-2 ROLAND LORD Service additionnel Additional service Q-23299-V-D-2 RENE GIGUERE Q-23299-V-D-1 RENE GIGUERE 3351 3843 2632 3844 2632 4126 6604 4116 4115 04-05-74 25-05-74 06-04-74 25-05-74 06-04-74 01-06-74 10-11-73 01-06-74 01-06-74 Q-1068 Q-1160 Q-946 Q-1166 Q-961 Q-1212 Q-344 Q-1186 Q-1185 Accordée / Granted Accordée / Granted Rejetée / Rejected Accordée / Granted Accordée / Granted Rejetée / Rejected Désistement Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted 5658 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCV-21\t30-07-74\tQ-500820 MAURICE MORIN Requérant-vendeur A pplica nt-vendor Q-502090 EDDY MORIN Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser\t4122\t01-06-74\tQ-1220\t La Commission: 1.Révoque, & toutes fins que de droit, l'attestation Q-500820 émise en faveur de Maurice Morin.2.Autorise en faveur de la partie requérante-acquéreur Eddy Morin, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel Dermis.QCV-22 30-07-74 Q-500234 VICTOR DUROCHER Requérant-vendeur A pplicant-vendor Q-502084 ROGER 8T-CYR Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser La Commission.1.Révoque, à toutes fins que de droit, l'attestation Q-500234 émise en faveur de Victor Durocher.2.Autorise en faveur de la partie requérante-acquéreur.Roger St-Cyr.la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-23 30-07-74 Q-502647 JEAN-PAUL BONNEAU Requérant-vendeur A pplicant-vendor Q-503182 DENIS GAUTHIER Requérant-acquéreur Applicant-purchaser La Commission: 1.Révoque, à toutes fins que de droit, l'attestation Q-502647 émise en faveur de Jean-Paul Bonneau._ 2.Autorise en faveur de la partie requérante-acquéreur Denis Gauthier, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.OPT-104 26-07-74 Q-200028 MAURICE AUGER Requérant-vendeur A pplicant-vendor Q-201992 GASTON QUIRIAULT Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser La Commission : 1.Autorise la suppression du transport par taxi donné par Maurice Auger.2.Révoque, à toutes fins que de droit, l'attestation Q-200028.3.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Gaston Qui-riault, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission a émettre tel permis.The Commission: 1.Revokes, for all legal purposes, certificate Q-500820 issued in behalf of Maurice Morin ; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Eddy Morin; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.4127 01-06-74 Q-1121 The Commission : 1.Revokes, for all legal purposes, certificate Q-600234 issued in behalf of Victor Durocher; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the ap\" plicant-purchaser.Roger St-Cyr; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.3840\t26-05-74\tQ-1161 \t\tQ-1162 The Commission: 1.Revokes, for all legal purposes, certificate Q-602647 issued in behalf of Jean-Paul Bonneau; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Denis Gauthier; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.4122 01-06-74 Q-1196 The Commission: 1.Authorizes the discontinuance of the transport by taxicab provided by Maurice Auger; 2.Revokes for all legal purposes certificate Q-200028; 3.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser Gaston Quiriault ; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n\" SZ 5659 No\tDate\tRequérants Applicant*\tC page\tl.O.Q.date\tCause Cote\tDécisions QPT-105\t26-07-74\tQ-200523-D-4 D-2 EDGAR TREMBLAY Requérant-vendeur A pplicant-vendor Q-200502-D-2 LUCIEN LEVESQUE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser\t4122\t01-06-74\tQ-1196\t La Commission: 1.Révoque, à toutes fins que de droit, l'attestation Q-200523 D-2 détenu par Edgar Tremblay; 2.Dispose des dossiers Q-200523 D-2 et Q-200523 D-4.3.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Lucien Leves-que.la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QPT-106 The Commission: 1.Revokes, for all legal purposes, certificate Q-200623 D-2 held by Edgar Tremblay; 2.Disposes of files Q-200523 D-2 and Q-200523 D-4.3.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Lucien Levesque; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.26-07-74 Q-201026-D-1 JEAN PARADIS Requérant-vendeur / Applicant-vendor Q-201030 BERTRAND PICARD Requérant-acquéreur A pplicant-purchaser 4112 01-06-74 Q-1172 La Commission: 1.Autorise la suppression du transport par taxi donné par Jean Paradis, en vertu de son attestation et révoque ladite attestation ; 2.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Bertrand Picard, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission & émettre tel permis.QPT-107 26-07-74 The Commission : 1.Authorizes the discontinuance of the transport by taxicab provided by Jean Paradis by virtue of his certificate, and revokes said certificate ; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Bertrand Picard; said certificate shall not by considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.Q-200701 WELLY DESBIENS Requérant-vendeur / Applicant-vendor Q-201511-D-2 ROSAIRE NEPTON Requérant-acquéreur Applicant-purchaser 1669 02-03-74 Q-743 La Commission : 1.Autorise la suppression du transport par taxi donné par Welly Desbiens en vertu de son attestation Q-200701 et révoque ladite attestation; 2.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Rosaire Nep-ton, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.The Commission: 1.Authorizes the discontinuance of the transport by taxicab provided by Wellv Desbiens by virtue of his certificate Q-200701, and revokes said certificate; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser Rosaire Nepton; said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QPT-108 26-07-74 Q-201387 ADONIA VACHON Requérant-vendeur / Applicant-vendor Q-201978 LORENZO LACHANCE Requérant>-acquéreur A pplicant-purchaser 4113 01-06-74 Q-1174 La Commission: 1.Autorise la suppression du transport par taxi donné par Adonia Vachon, en vertu de son attestation Q-201387 et révoque ladite attestation ; 2.Autorise en faveur du requérant-acquéreur Lorenzo La-chance, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.The Commission: 1.Authorizes the discontinuance of the transport by taxicab provided by Adonia Vachon, by virtue of his certificate Q-201387 and revokes said certificate; 2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Lorenzo Lachance; said certificate shall not be considered as permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QPT-109 TF 30-07-74 24005-D-l TF LA LIGUE DE TAXI DE RIMOUSKI Modification de tarifs Modification of tariffs 3352 04-05-74 Q-1071 Accordée / Granted -It il il I QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 No\tDate\tRequérants Applicant!\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QPT-110\t30-07-74\tQ-200045-D-1 AUTOBUS SEPT-ILES LIMITEE Requérante-venderesse A pplicant-vendor 202017 Mme THERESE RUEST DUBE Requérante-acquéreur A pplicant-purchaser\t4126\t01-06-74\tQ-1211\t La Commission: 1.Autorise la suppression du transport par taxi donné par Autobus Sept-Iles Limitée (Robert Nadeau) en vertu de son attestation Q-200046-D-1 et révoque ladite attestation.2.Autorise en faveur de la requérante-acquéreur Mme Thérèse Ruest Dubé, la délivrance d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.The Commission : 1.Authorizes the discontinuance of the transport by taxicab provided by Autobus Sept-Iles Limitée (Robert Nadeau) by virtue of its certificate Q-200045-D-1 and revokes said certificate.2.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-purchaser, Mrs.Thérèse Ruest Dubé: said certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.DECISIONS DE LA COMMISSION ¦ PROPRIO MOTU \u2022 / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION QCR-709 31-07-74 21508-V-P-l LAUREAT CANUEL La Commission révoque à toutes fins que de droit les clauses a et b du permis No 21508-V.4895 06-07-74 Q-1420 The Commission revokes, for all legal purposes, clauses a and b of permit No.21508-V.QCR-710 31-07-74 Q-7863-V-P-1 TRANSPORT MORNEAU INC.La Commission corrige sa décision QS-365 du 24 mai 1974 en ce qui a trait au numéro de dossier qui sera: 7863-V-S-3 et non 7863-V-S-l et du numéro de cause qui sera: Q-506 et non Q-288.4894 06-07-74 Q-1388 The Commission corrects its decision QS-365, dated May 24.1974, as regards the file number, which shall be: 7863-V-S-3 instead of 7863-V-S-l and the case number, which shall be: Q-506 instead of Q-288.QSM-31 31-04-74 25-N-P-l LA COMPAGNIE DE NAVIGATION TROIS-PISTOLES LIMITEE La Commission décrète la remise du cautionnement de 4895 06-07-74 Q-1400 S25.00 fait par Me Maurice Jacques au nom d'un groupe d'hommes d'affaires de Trois-Pietoles.QSM-32 31-07-74 269-N-P-l MARCEL DUFOUR La Commission dispose des cautionnements faits par le requérant et l'opposante comme suit : 1.Confisque le cautionnement de 850.00 fait par Marcel Dufour.2.Remet le cautionnement de 826.00 fait par Agence Maritime.QCV-17 26-07-74 Q-503919-P-1 I LEO MURDOCH La Commission décide qu'il n'y a pas lieu de modifier, révoquer ou confirmer la décision QCV-A-2 du 7 mai 1974.QPV-330 The Commission orders the reimbursement of the 825.00 deposit made by Me Maurice Jacques, on behalf of a group of businessmen of Trois-Pistoles.4895 06-07-74 Q-1402 The Commission disposes as follows of the deposits made by the applicant and the opponent : 1.Confiscates the 850.00 deposit made by Marcel Dufour: 2.Refunds the 825.00 deposit made by Agence Maritime.4893 06-07-74 Q-1362 _ The Commission decides that there is no ground for amending, revoking or confirming decision QCV-A-2 dated May 7.1974.06-07-74 Q-1398 26-07-74 1650-A-P-l 4895 I LES AUTOBUS LACHANCE INC.MA^aCom,mJfi.0ft'î,Corrige le deuxieme considérant page 2 de la The Commission corrects the second preamble, on page 2 of decision yrv-rfu^.decision QPV-302.QL-168 31-07-74 1153-DY-P-l ELPHEGE BELANGER La Commission révoque & toutes fins que de droit le permis 1153-DY détenu par Elphège Bélanger.4895 06-07-74 Q-1403 The Commission revokes, for all legal purposes, permit 1153-DY held by Elphège Bélanger.\"~ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 82 5661 No\tDate\tRequérants Applicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QL-169\t31-07-74\t1238-DY-P-l CAMPWAGON (Johan Roy, Lucien Barbeau et / and Raymond Moisan)\t4895\t06-07-74\tQ-1401\t La Commission décrète la remise du dépôt de $25.00 fait par les requérants.QL-170 31-07-74 The Commission orders the reimbursement of the $25.00 deposits made by the applicants.4895 00-07-74 Q-1404 772-DY\u2014P\u20141 CLAUDE GUERTIN LOCATION La Commission révoque à toutes fins que de droit le permis The Commission revokes, for all legal purposes, permit No.No 772-DY détenu par Claude Guertin Location.772-DY held by Claude Guertin Location.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS QCR-708 01-08-74 Q-7041-V-D-3 TRANSPORT AMEDEE CAYER INC.La Commission : 1.Rejette la partie No 1 de la requête; 2.Prend acte du désistement de la requérante de la partie 4 de sa requête ; 3.Accorde en partie la requête.QPV-334 01-08-74 02-03-74 Q-814 The Commission : 1.Rejects part No.1 of the request; 2.Records the applicant's withdrawal of part 4 of its request; 3.Grants the request in part.3459-AT-D-l CLAUDE BOURBEAU Service additionnel / Additional service Q-1019 Accordée / Granted PERMIS SPECIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions QS-490 23914-V-S-l 5427-V QS-491 7571-V-S-2 Cause /Case: Q-496 SYNNETT, JEAN BERNARD Voiturier-remorqueur Haulaway operator RIMOUSKITRANSPORT LIMITEE Voiturier-roulier / Carrier Cause / Case: Q-489 McMAHON TRANSPORT LTEE Du 25 juillet 1974 jusqu'au 1er juillet 1975 ou décision finale de la Commission selon l'événement qui se présentera le premier./From July 26, 1974 until July 1, 1976, or pending a final decision of the Commission, whichever occurs first.Du 29 juillet 1974 au 1er juillet 1975 ou jusqu'à décision finale de laCommission sur la demande de permis permanent selon I'éventua- Demande parue dans le journal « A Propos » les 2, 3 et 4 juillet 1974./ Request published in the newspaper \"A Propos\" on July 2, S and 4, 1974- Accordée / Granted Demande parue dans le journal « Le Devoir \" les 7, 8 et 10 juillet 1974./ Request published in the newspaper \"Le Devoir ' on July 7, 8 and 10, the newspaper 1974.Accordée / Granted 5662 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 No du répertoire chronologique Chronoloçicat Repertory No.QS-»92 Q-23861-V-S-1 17376-V QS-493 Q-500004-S-002 QS\u2014194 Q-6000O4-S-OO1 Nom du requérant Name of A pplicant Cause ICaee: Q-400 MARCEL HOULE Voiturier-remorqueur Haulaway operator KINGSWAY FREIGHT LINES LIMITED Voiturier-roulier / Carrier Cause I Case: Q-503 TRANSBOIS INC.Cause I Case: Q-602 TRANSOBIS INC.Validité: de:.à Validity Period litê qui se présentera la première./ From July 29, 1974 until July 1, 1976, or pending a final decision of the Commission regarding the application for a permanent permit, whichever occurs first.Du 29 juillet 1974 au 1er mai 1975 ou jusqu'à décision finale de la Commission selon l'éventualité qui se présentera la première.Prom July 29, 197410 May 1, 1976 or pending final decision by the Commission, whichever occurs first.Pour une période de six (6) mois ou jusqu'à décision finale de la Commission, selon l'événement qui se présentera le premier, à partir du 29 juillet 1974.From July 26, 1974 to the end of a six-month period or pending a final decision of the Commission, whichever occurs first.Pour une période de six (6) mois ou jusqu'à décision finale de la Commission, selon l'événement qui se présentera le premier à partir du 29 juillet 1974.From July 29, 1974 to the end of a six-month Détails des demandes et des décisions Particulars of applications and decisions Demande parue dans le journal < Le Devoir > les 14, 15 et 16 mai 1974./ Request published in the newspaper \"Le Devoir\" on May 14, 16 and 16,1974- Accordée / Granted Demande parue dans le journal « Le Soleil > les 13.15 et 16 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"Le Soleil ' on July 13,16 and 16,1974.Accordée / Oronied Demande parue dans le journal \u2022 Le Soleil \u2022 les 13, 15 et 16 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"Le Soleil ' on July IS, 16 and 16.1971.Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106- année, n° 32 5663 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails des demandes et des décisions Particular* of application* and decision* QS-496 1333-DY 4 1139-DYV-S-l QS-496 262-N-S-l QS-497 1888-A-S-l QS-498 23847-V-S-2 Q8-499 1161-DYV-S-l Q8-500 21248-V-S-l QS-501 15967-V-S-10 QS-502 Q-603110-S-l Cause / Cote: Q-439 GRONDIN LEASING INC.LOCATION GRONDIN INC.Cause /Cote: Q-490 TRAVERSE TROIS-PISTOLES ESCOUMINS LTEE Cause /Case: Q-504 AUTOBUS TREMBLAY PARADIS INC.Cause / Cote: Q-474 LAVOIE TEXACO SERVICE ENRG.SERVICE DE LOCATION TRANSCO INC.Cause/Case: Q-482 FERNAND GIROUX Cause / Case: Q-501 GERARD NOLIN LIMITEE Cause / Cote: Q-494 CONRAD GAUDREAU period or pending a final decision of the Commission, whichever occurs first.Du 18 juin au 31 décembre 1974 Prom June IS, 1974 US December SI, 1974.27 juilllet 10 août 1974.July S7 August 10, 1674- Du 25 juillet 1974 au 31 août 1974.From July 26, 1974 to August 31, 1974.Pour une période de huit (8) mois à partir du 24 juillet 1974./ For an eight-(8) month period starting from July 24, 1974- Du 1er août au 15 septembre 1974./ From August 1 to September lâ, 1974.Du 25 juillet au 3\".octobre 1974./ From July 26 to October SI, 1974.Pour une période de six (6) mois ou jusqu'à décision finale de la Commission à partir du 25 juillet 1974.From July 29, 1974 to the end of a six-month period or pending a final decision of the Commission, whichever occurs first.Demande parue dans le journal « Le Nouvelliste » les 1er.2 et 3 mai 1974./ Application published in the newspaper \"Le Nouvelliste\" on May 1, 2 and S, 1974.Accrodée / Granted Demande parue dans le journal t A Propos «, les 3.4 et 6 juillet 197t./ Application published in the newspaper \"A Propos\" on July S, 4 and 6,1974.Accordée / Granted Demande parue dans le journal « Le Soleil ¦ les 10, 11 et 12 juillet 1974 / Application published in the newspaper \"Le Soleil\" on July 10, 11 and 12,1974- Accordée / Granted Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 12.13 et 14 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"Le Quotidien\" on July 12, 13 and 14, 1974.Accordée / Granted Demande parue dans le journal ¦ A Propos > les II, 12 et 13 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"A Propos\" on July 11, It and IS, 1974.Rejetée / Rejected Demande parue dans le journal « A Propos \u2022 leB 16, 16 et 17 juin 1974.1 Application published in Me newspaper \"A Propos\" on June 16, 16 and 17, 1974.Accordée / Granted Demande parue dans le journal \u2022 A Propos > les 4, 6 et 6 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"A Propos ' on July 4, 6 and 6 1974- Accordée / Granted Demande parue dans le journal \u2022 Le Devoir » les 3, 4, 5 et 6 juin 1974.1 Application published in the newspaper \"Le Devoir\" on June S, 4, 6 and 6, 1974- Accordée / Granled 5664 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails des demandes et des décisions Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of applications and decisions QS-503 3652-V-S-3\tCause /Cote: Q-607 TRANSPORT THEBERGE LIMITEE\tModification de la clause c jusqu'à décision finale de la Commission.Modification of clause c pending the final decision of the Commission.\tDemande parue dans le journal « A Propos » les 12, 13 et 14 juillet 1974./ Application published in the newspaper \"A Propos\" on July IS, IS and 14, 1974.Accordée / Granted 58086-0\t\t\t \tAvis divers\t\tMiscellaneous Notices Succession Thérèse Bolduc Prenez avis que M.Dieudonnc Bolduc, cultivateur, demeurant à St-Méthode, comté de Frontenac, province de Québec, et en sa qualité de tuteur à Lucien Bolduc, Marielle Bolduc, Lucienne Bolduc et Roger Bolduc, en vertu d'un jugement de la Cour Supérieure, district de Beauce, rendu le 6 février 1974, et jugement corrigé rendu par ladite Cour Supérieure, le 26 mars 1974, dossier No 350-14-000014-74 des dossiers de ladite Cour, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Beauce, le 4 avril 1974, sous le numéro 264111, a accepté sous bénéfice d'inventaire, pour et au nom seulement desdits enfants mineurs, la succession de feu Thérèse Bolduc, tel qu'il appert d'un acte reçu devant Me Hermann Mathieu, notaire, le 28 juin 1974, sous le No 1410 de ses minutes, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Frontenac, à Lac Mégantic, P.Q., le 23 juillet 1974, sous le numéro 109561.le tout en conformité des dispositions des articles 660 et suivants du Code civil de la province de Québec, le tout, à toutes fins que de droit.Fait et donné à St-Éphrem, comté de Beauce, P.Q., ce 30e jour de juillet 1974.(Sceau) Le procureur, 58125-0 Hermann Mathieu, notaire.Estate of Thérèse Bolduc Notice is given that Mr.Dieudonné Bolduc, agriculturist, residing in Saint-Méthode, County of Frontenac, Province of Québec, in his capacity as tutor to Lucien Bolduc, Marielle Bolduc, Lucienne Bolduc and Roger Bolduc, pursuant to a judgment of the Superior Court, District of Beauce, given on February 6, 1974, and to the amended judgment given by said Superior Court on March 26.1974, file No.350-14-000014-74 in the records of the said Court, registered in the Beauce Registry Office, on April 4, 1974, under number 264111, has accepted, under benefit of inventory, for and in behalf of said minor children only, the estate of late Thérèse Bolduc, as it appears from a deed executed before Hermann Mathieu, Notary, on June 28, 1974, under number 1410 of his minutes draft, registered in the Frontenac Division Registry Office, in Lac Mégantic, P.Q., on July 23, 1974, under number 109561, the whole in accordance with the provisions of articles 660 and following of the Civil Code of the Piovince of Québec, the whole, for all legal purposes.Given in Saint-Ephrem, County of Beauce, P.Q., the 30th day of July 1974.(Seal) Hermann Mathieu, Notary, 58125 Attorney.Succession Philippe Corbeil La soussignée, Lise Bouret, veuve de Philippe Corbeil, donne avis qu'elle a accepté sous bénéfice d'inventaire la succession dudit Philippe Corbeil, décédé à Montréal le 16 mai 1974, ainsi qu'il appert d'une déclaration reçue devant Me Roger Comtois, notaire, le 18 juin 1974, enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Montréal, le 3 juillet 1974, sous le No 2532494._ Montréal, le 31 juillet 1974.58133-0 Lise Bouret.Estate of Philippe Corbeil The undersigned, Lise Bouret, widow of Philippe Corbeil, gives notice that she has accepted under benefit of inventory the estate of the said Philippe Corbeil, who deceased in Montreal on May 16, 1974, as it appears from a declaration executed before Me Roger Comtois, notary, on June 18, 1974, registered in the Division of Montreal Registry Office on July 3, 1974, under number 2532494.Montreal, July 31, 1974.58133 Lise Bouret. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 38 5665 CENTRE D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE RIMOUSKI Avis est donné qu'en vertu des articles 56 et 47 de la I/>i de l'Université du Québec (1968, chapitre 66), le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé par l'arrêté en conseil 2573-74 du 17 juillet 1974 l'annulation des lettres patentes du Centre d'études universitaires de Rimouski émises le 3 septembre 1969 et que ladite annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre de l'éducation, 58127-0 Pierre Martin.CENTRE D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE RIMOUSKI Notice is given that pursuant to Sections 56 and 47 of the University of Québec Act (1968, chapter 66), the Lieutenant-Governor in Council has approved the annulment of letters patent of the Centre d'études universitaires de Rimouski, issued on September 3, 1969, by Order in Council 2573-74 dated July 17, 1974.Said annulment shall be effective on the sixtieth day following the publication of the present notice in the Québec Official Gazette.Pierre Martin, 58127 Deputy Minister of Education.LAKE MEGANTIC PULP COMPANY Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par l'arrêté en conseil No 2585, en date du 17 juillet 1974, d'approuver le règlement numéro 16 de la compagnie « LAKE MEGANTIC PULP COMPANY », réduisant son capital, conformément aux articles 12 et suivants de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations, Statuts refondus, 1964, chapitre 275.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58083-o 690-1893 LAKE MEGANTIC PULP COMPANY The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that it has pleased the Lieutenant-Governor in Council, by Order in Council No.2585, dated July 17, 1974, to approve bylaw number 16 of \"LAKE MEGANTIC PULP COMPANY\", reducing its capital, in conformity with sections 12 et sequentur, of the Special Corporate Powers Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 275.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58083 690-1893 Succession Ernest Ashmele Avis est donné que Ashley Jefferson Ashmele, demeurant à 5752 rue Fleet, Hampstead, Québec, et Shirley Frances Ashmele, épouse de Max Fox, demeurant à 940 rue Bellevue, Halifax, Nouvelle-Ecosse, ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de leur père, feu Ernest Ashmele, et son vivant, de Montréal, Québec et y décédé le 4 juin 1973, suivant acte en date du 14 février, 1974, devant Me Abraham Polger, notait e de Montréal, Québec, et dont copie a été enregistrée au bureau d'enregistrement de Montréal, Québec, le 20 février, 1974, sous le numéro 2494560.Montréal, Québec, ce 31e jour de juillet, 1974.Les procureurs, Greenblatt, Godinskv, Resin 58126-0 i & Uditsky.Estate of Ernest Ashmele Notice is hereby given that Ashley Jefferson Ashmele, residing at 5752 Fleet Street, Hampstead, Québec and Shirley Frances Ashmele, wife of Max Fox, residing at 940 Bellevue Street, Halifax, Nova Scotia, have accepted under benefit of inventory the estate of their late father, Ernest Ashmele, in his life time of Montreal, Québec, and there deceased on June 4th, 1973, as per deed of acceptance under benefit of inventory dated February 14th, 1974, passed by Me Abraham Polger, Notary of Montreal, Québec, a copy of same having been duly registered at the registry office, Montreal, Québec, on February 20th, 1974, under No.2494560.Signed at Montreal, Québec, this 31st day of July, 1974.Greenblatt, Godinsky, Resin & Uditsky, 58126-0 Attorneys.Succession Denis Doyon Prenez avis que dame Pauline Chapleau, veuve Denis Doyon résidant au 78C, L.H.Desjardins Terrebonne Que., tant personnellement qu'ès-qualité de tutrice à ses enfants mineurs, a accepté la succession de son époux sous bénéfice d'inventaire, suivant acte enregistré à Terrebonne, sous le No 444883.Le notaire.58086-o J.Théo Lecault, Jr.Estate of Denis Doyon Notice is given that Mrs.Pauline Chapleau, widow of the late Denis Doyon, residing at 786 L.H.Desjar-dins, Terrebonne, Québec, in her capacity of tutor to her minor children, has accepted, under benefit of inventory, the estate of her husband, under the terms of a deed registered in Terrebonne, under No.444883.J.Théo.Legault, Jr.58086 Notary. 5666 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Succession Derek Brown Avis public est donné concernant la succession de M.Derek Brown que Dame Karja Van Den Brink en sa qualité de tutrice à sa fille Jessica Brown a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de Derek Brown.L'acceptation sous bénéfice d'inventaire a été passée devant Me Gilbert Lord, notaire, du 1019, St-Cyrille, Québec, le 10 juin 1974 à Québec et enregistrée au bureau d'enregistrement de Montréal le 17 juin 1974 sous le numéro 2528452.Les procureurs, 58105-o Langlois, Drouin & Laflamme.Estate of Derek Brown Public notice is given with respect to the estate of Mr.Derek Brown, that Mrs.Karja Van Den Brink, in her capacity as tutrix to her daughter, Jessica Brown, has accepted, under benefit of inventory, the estate of Derek Brown.The said acceptance under benefit of inventory was executed before Me Gilbert Lord, notary, 1019 St.Cyrille, Québec, on June 10, 1974, in Québec City, and registered at the Montreal Registry Office on June 17, 1974, under number 2528452.Langlois, Drouin & Laflamme, 58105 Attorneys.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Act Applications Joseph-Lucien-Terence Côté Avis est donné que Joseph-Lucien-Terence Côté, camionneur, domicilié au 59, rue Salaberry est, à Mercier, district de Beauharnois, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin qu'un décret soit accordé changeant son nom en celui de Joseph-Lucien-Terence Morand.Le 18 juillet 1974.Les avocats du requérant, Hébert, Laberge, Montpetit, 58041-31-2-o Lafontaine & Mercier.Mary Margaret Géraldine Cartier Avis est par les présentes donné que Mary Margaret Géraldine Cartier, domiciliée et résidant à 862 rue Charron, dans les cité et district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice pour obtenir un ordre changeant son nom en celui de Mary Margaret Géraldine Susan Cartier.Aucune autre personne ne sera affectée par ce changement de nom.Montréal, le 4 juillet 1974.Les procureurs de la requérante, Baatz, Sylvestre, Cyr 58025-31-2-o & Cohen.Adrien Cauchon Avis est donné que Adrien Cauchon, douanier, domicilié au 5910 rue De Meaux, Montréal, district de Montréal, présentera au lieutenant-gouverneur en conseil une requête pour le changement de son nom en celui de Adrien Gilbert, ce changement de nom devant aussi profiter à son épouse, Marie-Claire Duquette, et aux deux enfants mineurs, Diane et Michel, nés de ce mariage.Montréal, le 25 juillet 1974.Le procureur du requérant, 58072-31-2-o Louise Boucheh-M ackay.Joseph-Lucien-Terence Côté Notice is given that Joseph-Lucien-Terence Côté, truck driver, domicilied at 59, Salaberry East, in Mercier, district of Beauharnois, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Joseph-Lucien-Terence Morand.July 18, 1974.Hébert, Laberge, Montpetit, Lafontaine & Mercier, 58041-31-2-o Attorneys for the Petitioner.Mary Margaret Géraldine Cartier Notice is hereby given that Mary Margaret Géraldine Cartier, domiciled and residing at 862 Charron Street, in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Justice for an order changing her name to that of Mary Margaret Géraldine Susan Cartier.This change of name will affect no other person.Montreal, July 4, 1974.Baatz, Sylvestre, Cyr & Cohen, 58025-31-2-o Attorneys for applicant.Adrien Cauchon Notice is hereby given that Adrien Cauchon, customs officer, residing and domiciled at 5910 De Meaux, at the City of Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Adrien Gilbert, which change will also benefit his wife, Marie-Claire Duquette, as well as their two minor children, Diane and Michel, born of the said marriage.Montreal, July 25th, 1974.Louise Boucher-Mackay, 58072-31-2-o Attorney for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5667 Louise Beauchamp Avis est donné que Louise Beauchamp, étudiante, résidant et domiciliée au 9123A, rue Jamay, à Saint-Léonard, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice de la province de Québec, en vue d'obtenir du lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de Louise Laçasse.Montréal, ce 25 juillet 1974.Le procureur de la requérante, 58063-31-2-o Johanne Gagnon Trudel.Ray monde Bergeron Avis est par les présentes donné que Mlle Raymonde Bergeron, infirmière, résidant au 235 Sherbrooke Ouest, app.204, Montréal, Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom de Raymonde Bergeron pour celui de Maude Bergeron.Montréal, le 24 juillet 1974.Le procureur de la requérante, 58040-31-2-0 Me Luc Le Blanc.Joseph Roméo Victor Michel, dit Michel Villeneuve Avis est par les présentes donné que M.Joseph Roméo Victor Michel, dit Michel Villeneuve, domicilié à St-Jérôme, district de Terrebonne, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph Roméo Victor Michel Villeneuve.Le procureur du requérant, 58042-31-2-o André Saumis.Maurice Richard Chalifoux Avis est par les présentes donné que Maurice Richard Chalifoux, demeurant au 6746 rue Wawerley, en les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Anne-Marie Chalifoux.Montréal, ce 24 juillet 1974.Le procureur du requérant, 58043-31-2-o André Gauthier.Paul Corbeil Avis est par les présentes donné que Paul Corbeil, domicilié au 3301 du boulevard Gouin est, app.1, en la ville de Montréal-Nord, district de Montréal, s'adressera au lieuteuant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Paul-Yvon Gélinas.Montréal, le 30 juillet, 1974.Les procureurs du requérant, Cloutier, Tellier, Cayer, 58106-32-2-o Dumais & Corbeil.Louise Beauchamp Notice is hereby given that Louise Beauchamp, student, residing and domiciled at 9123A, Jamay Street, Saint-Léonard, district of Montreal, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec, for a decree of the Lieutenant-Governor in Council, changing her name to Louise Laçasse.Montreal, July 25th, 1974.Johanne Gagnon Trudel, 58063-31-2-o Attorney for petitioner.Raymonde Bergeron Notice is hereby given that Miss Raymonde Bergeron, nurse, residing at 235 Sherbrooke W., Apt.204, Montreal, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name from Raymonde Bergeron to that of Maude Bergeron.Montreal, July 24th, 1974.Mtre Luc Le Blanc, 58040-31-2-o Attorney for the Petitioner.Joseph Roméo Victor Michel, dit Michel Villeneuve Notice is hereby given that Mr.Joseph Roméo Victor Michel, alias Michel Villeneuve, residing at St-Jérôme, district of Terrebonne, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Joseph Roméo Victor Michel Villeneuve.André Saumis, 58042-31-2-o Attorney for the Petitioner.Maurice Richard Chalifoux Notice is given that Maurice Richard Chalifoux, residing at 6746 Wawerley Street, city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of Québec to change his name to Anne-Marie Chalifoux.Montreal, July 24th 1974.André Gauthier, 58043-31-2-o Attorney of Applicant.Paul Corbeil Notice is hereby given that Paul Corbeil, residing at 3301 east boulevard Gouin, Apt.1 of Montreal-North, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of a decree changing his name to Paul-Yvon Gélinas.Montreal, this July 30, 1974.Cloutier, Tellier, Cayer, Dumais & Corbeil, 58106-32-2-o Attorneys for petitioner. 5668 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Francine Tétreault Francine Tétreault, ménagère, résidant et domiciliée au 8270 rue St-Hubert, app.3, ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Francine Bédard.Les procureurs de la requérante, Lafontaine, Thibault & 58064-31-2-o Lafontaine.Francine Tétreault Francine Tétreault, housekeeper, residing and domiciled at 8270 St.Hubert Street, Apt.3, city and district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing her name to that of Francine Bédard.Lafontaine, Thibault & Lafontaine, 58064-31-2-o Attorneys for the petitioner.Claudette Daigle Tremblay Avis est donné par les présentes que Dame Claudette Daigle Tremblay, infirmière et étudiante, domiciliée et résidant à 1268 rue Commerciale, à St-Romuald, district de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom pour celui de Claude d'Aigle Tremblay.58055-31-2-0 Claudette Daigle Tremblay Notice is hereby given that Mrs.Claudette Daigle Tremblay, nurse and student, domiciled and residing at 1268 Commerciale Street, in Saint-Romuald, District of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an order changing her name to that of Claude d'Aigle Tremblay.58055-31-2 Marchelline Joseph Fernandez Marchelline Joseph Fernandez, gentilhomme, domicilié et résidant au numéro 1254, rue St-Marc, app.33, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Marcel Heffler.Montréal, ce 29e jour de juillet 1974.L'avocat, 58107-32-2-o Bernard Sepinwali.Marchelline Joseph Fernandez Marchelline Joseph Fernandez, gentleman, of the city and district of Montreal, therein residing and domiciled at 1254 St.Mark Street, Apt.33, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Marcel Heffler.Montreal, this 29th day of July, 1974.Bernard Sepinwall, 58107-32-2-o Attorney.Jean-Guy Therrien Avis est donné que Jean-Guy Therrien, célibataire, domicilié et résidant à 735 rue St-Olivier, Québec, district de Québec a déposé une requête auprès du ministre de la justice de la province de Québec pour changer son nom de Jean-Guv Therrien en celui de Daniel Gill.Québec, ce 30 mai 1974.Les procureurs du requérant, 58108-32-2 Sirois, Laperriére & Lemire.Jean-Guy Therrien Notice is given that Jean-Guy Therrien, bachelor, domiciled and residing at 735 St.Olivier Street, Québec, District of Québec, will apply to the Minister of Justice of the Province of Québec for an order changing his name of Jean-Guy Therrien to that of Daniel Gill.Québec, May 30, 1974.Sirois, Laperriére & Lemire, 58108-32-2-o Attorneys for the applicant.Gaétan Lachance dit Lamarche Avis est donné que Gaétan Lachance dit Lamarche, résidant et domicilié à 974 boulevard St-Joseph, à Roberval, district de Roberval, s'adressera au ministre de la justice afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Joseph-Fernand-Gaétan Lachance-Lamarche conformément aux dispositions de la Loi de changement de nom (L.Q.1965 chapitre 77).Roberval, le 8 juillet 1974.Le procureur du requérant, 58129-32-2-0 Roland Bergeron.Gaétan Lachance dit Lamarche Notice is given that Gaétan Lachance dit Lamarche, residing and domiciled at 974, St-Joseph Blvd., in the city and district of Roberval, District of Roberval, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to that of Joseph-Fernand-Gaétan Lachance-Lamarche in conformity with the provisions of the Change of Name Act (S.Q.1965, chapter 77).Roberval, July 8, 1974.Roland Bergeron, 58129-32-2-o Attorney for the petitioner. GAZETTE OEGICIELLE DU QUEBEC, 10 août 1974, 100- année, n' 32 Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Elliot Elias Arditi II a plu au lieutenant gouverneur en conseil, par le décret numéro 2532 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Elias Arditi en celui de Elliot Elias Arditi.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.u.Leopold Aubin Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2533 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph-Leopold Mignault en celui de Leopold Aubin.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Evelyne Bolduc Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2534 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Marie Éva Bolduc en celui de Evelyne Bolduc.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Murray Boxenbaum Bowen Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2535 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Moszek Sumor (Morris) (Bok-senbaum) Boxenbaum en celui de Murray Boxenbaum Bowen.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Joseph Georges Germain Gélinas Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2536 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph-Georges-Edgar Gélinas en celui de Joseph Georges Germain Gélinas.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Katherine Lynn Hrycko Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2537 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Katherine Lynn McNutt en celui de Katherine Lynn Hrycko.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.5669 Change of name \u2014 Act Granted Elliot Elias Arditi It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Elias Arditi to that of Elliot Elias Arditi, by order number 2532, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Leopold Aubin It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Leopold Mignault to that of Leopold Aubin, by order number 2533, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Evelyne Bolduc It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Éva Bolduc to that of Evelyne Bolduc, by order number 2534, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Murray Boxenbaum Bowen It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Moszek Sumor (Morris) Boksen-baum) Boxenbaum to that of Murray Boxenbaum Bowen, by order number 2535, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy M in ister of Justice.Joseph Georges Germain Gélinas It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Georges-Edgar Gélinas to that of Joseph Georges Germain Gélinas by order number 2536, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Katherine Lynn Hrycko It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Katherine Lynn McNutt to that of Katherine Lynn Hrycko, by order number 2537, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice. 5670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.S3 Joseph Albert Marcel Lavoie Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2538 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph-Albert-Marcel Berger en celui de Joseph Albert Marcel Lavoie.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-0 Robert Normand, c.r.Joseph Léo Alfred Richard Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 2539 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Joseph-Léo-Alfred Guillemette en celui de Joseph Léo Alfred Richard.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Catherine Ruth Solomon Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, pai le décret numéro 2540 du 17 juillet 1974 d'effectuer le changement de nom de Chaya Reigal Solomonovitch en celui de Catherine Ruth Solomon.Québec, le 26 juillet 1974.Le sous-ministre de la justice, 58103-o Robert Normand, c.r.Joseph Albert Marcel Lavoie It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Albert-Marcel Berger to that of Joseph Albert Marcel Lavoie, by order number 2538.dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minuter of Justice.Joseph Léo Alfred Richard It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Léo-Alfred Guillemette to that of Joseph Léo Alfred Richard, by order number 2539, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Catherine Ruth Solomon It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Chaya Reigal Solomonovitch to that of Catherine Ruth Solomon, by order number 2540, dated July 17, 1974.Québec, July 26, 1974.Robert Normand, q.c, 58103 Deputy Minister of Justice.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions CAISSE D'ECONOMIE ENOQ (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 29 septembre 1973 par la « CAISSE D'ECONOMIE ENOQ», changeant son groupe qui était « L'Association des enseignants du Nord-Ouest Québécois » en celui de « Centre d'Orientation l'Étape Inc., Clair Foyer Inc., Commission Scolaire Régionale du Cuivre, Commission Scolaire Régionale Harricana, Commission Scolaire Régionale Lalonde, Commission Scolaire Régionale La Vérendrye, Commission Scolaire d'Amos, Commission Scolaire de Barraute-Senneterre, Commission Scolaire de Bellefeuille, Commission Scolaire de Chapais-Chibougamau, Commission Scolaire de Joutel-Matagami, Commission Scolaire de Lac Abi-tibi, Commission Scolaire de La Forêt, Commission Scolaire du Lac Témiscamingue, Commission Scolaire de Malartic, Commission Scolaire de Quévillon, Commission Scolaire de Rouyn, Commission Scolaire de Rouyn-Noranda, Commission Scolaire de Val d'Or, La Maison (Rouyn-Noranda) Inc., Northwestern Québec School Board, Université du Québec à Rouyn ».Québec, le 24 juillet 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58115-0 Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE ENOQ (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bvlaw adopted on September 29, 1973, by the \"CAISSE D'ECONOMIE ENOQ\", changing its group, which was \"L'Association des enseignants du Nord-Ouest Québécois\" to that of \"Centre d'Orientation l'Étape Inc., Clair Foyer Inc., Du Cuivre Regional School Board, Harricana Regional School Board, Lalonde Regional School Board, La Vérendrye Regional School Board, Amos School Board, Barraute-Senneterre School Board, Bellefeuille School Board, Chapais-Chibougamau School Board, Joutel-Matagami School Board, Lac Abitibi School Board, La Forêt School Board, Lac Témiscamingue School Board, Malartic School Board, Quévillon School Board, Rouyn School Board, Rouyn-Noranda School Board, Val d'Or School Board, La Maison (Rouyn-Noranda) Inc., Northwestern Québec School Board, University of Québec in Rouyn\".Québec, July 24, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 58115 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° S2 5671 CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE GRANBY (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 27 février 1974 par la « CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE GRANBY », changeant son groupe qui était « les travailleurs des corporations, institutions ou sociétés suivantes: Montrose Worsted Mills, Hafner Fabrics, Thor Mills, Simond Canada Saws, Roulotte Champlain, Garage Gemme et Alix » en celui de « les travailleurs des corporations, institutions ou sociétés suivantes: Montrose Worsted Mills Inc., Hafner Fabrics of Canada Ltd., Thor Mills Ltd., Simonds Canada Saw Co.Ltd., Roulottes Champlain Ltée, Garage Gemme et Alix Inc., Construction St-Paul Ltée, Boulangerie Racine Ltée, Paragon Inc., Slack Brothers Limited, Klockner-Moeller Ltée, Sinimex Inc., La Voix de l'Est Ltée, Coopérative Agricole de Granby ».Québec, le 24 juillet 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58114-o Albert Jessop.CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE GRANBY (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on February 27, 1974, by the \"CAISSE D'ECONOMIE DES TRAVAILLEURS DE GRANBY\", changing its group, which was \"the workers of the following corporations, institutions or associations: Montrose Worsted Mills, Hafner Fabrics, Thor Mills, Simond Canada Saws, Roulotte Champlain, Garage Gemme et Alix\" to that of \"the workers of the following corporations, institutions or associations: Montrose Worsted Mills Inc., Hafner Fabrics of Canada Ltd., Thor Mills Ltd., Simonds Canada Saw Co.Ltd., Roulottes Champlain Ltée, Garage Gemme et Alix Inc., Construction St-Paul Ltée, Boulangerie Racine Ltée, Paragon Inc., Slack Brothers Limited, Klockner-Moeller Ltée, Sinimex Inc., La Voix de l'Est Ltée, Coopérative Agricole de Granby\".Québec, July 24, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 58114 Companies and Cooperatives.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses GAC PRIVATE BRANDS LIMITED Avis es! donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « GAC PRIVATE BRANDS LIMITED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Ivan E.Phillips, 1 Place Ville-Marie, suite 930, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au 3535, chemin de la Reine Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58083 1356-3564 LORAM CO.LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 5e jour de juillet 1974, il a accordé un nouveau permis à la compagnie « LORAM HOLDINGS LTD.», l'autorisant à exercer son commerce dans la province de Québec sous son nouveau nom de « LORAM CO.LTD.», conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères, Statuts refondus, 1964, chapitre 282.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58083 PA: 40-72 GAC PRIVATE BRANDS LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"GAC PRIVATE BRANDS LIMITED\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Ivan E.Phillips, Esquire, suite 930, 1 Place Ville-Marie, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 3535 Queen Mary Road, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58083-o 1356-3564 LORAM CO.LTD.Notice is given that, on 5th day of July, 1974, a new license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"LORAM HOLDINGS LTD.\", authorizing it to carry on business in the Province under its new name of \"LORAM CO.LTD.\", pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 282.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives.58083-o PA: 40-72 5672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 19?4, Vol.106, No.32 Associations cooperatives ASSOCIATION COOPERATIVE DES ARTISANS D'AMOS {Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « ASSOCIATION COOPERATIVE DES ARTISANS D'AMOS ».Le siège social de cette association coopérative est situéàAmos.Québec, dans le district électoral d'Abitibi-ouest.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58128-0 Albert Jessop.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Bolton Cadastre officiel du canton de Bolton, municipalité d'Austin*, division d'enregistrement de Brome.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 1429-33 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 20 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Cap-de-la-Madeleinc Cadastre officiel de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine, municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Made-leine*, division d'enregistrement de Champlain.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 88-2 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 2 juillet 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Village de Como Cadastre officiel du village de Como, municipalité de la ville de Hudson, division d'enregistrement de Vaudreuil.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 58-35 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 juillet 1974.Cooperative Associations ASSOCIATION COOPERATIVE DES ARTISANS D'AMOS (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, has approved the formation of \"ASSOCIATION COOPERATIVE DES ARTISANS D'AMOS\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Amos, P.Q., in the Electoral District of Abitibi-West.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 58128 Companies and Cooperatives.Department of Lands and Forests Cadastre Township of Bolton Official cadastre of the township of Bolton, municipality of the Austin*, registration division of Brome.Notice is hereby given that a part of lot 1429-33 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 20, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Parish of Cap-de-la-Madeleine Official cadastre of the parish of Cap-de-la-Madeleine, municipality of Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Made-leine*, registration division of Champlain.Notice is hereby given that a part of lot 88-2 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, July 2, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Miriister.Village of Como Official cadastre of the village of Como, municipality of the town of Hudson, registration division of Vaudreuil.Notice is hereby given that a part of lot 58-35 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, July 15, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 581 IO-o For the Deputy Minister.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g. GAZETTE OFGICIELLE DU QUÉBEC.10 août 19?4, 106- année.n° 32 Canton de Duhamel Cadastre officiel du canton de Duhamel, municipalité du village de Lorrainville, division d'enregistrement de Témiscamingue.Avis est par la présente donné que les lots 34-39 à 34-46, 34-58, 35-6 du rang VI sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 17 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Canton de Duhamel Cadastre officiel du canton de Duhamel, municipalité du village de Lorraineville, division d'enregistrement de Témiscamingue.Avis est par la présente donné que les lots 33-8 à 33-11, 33-13 à 33-18 et qu'une partie du lot 33-12 du rang VU sont annulés et intégrés au lot 33-1 en vertu des articles 2174 et 2174a du Code civil.Québec, le 4 juillet 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard a.-g.Canton de Hull Cadastre officiel du canton de Hull, municipalité de la ville de Touraine, division d'enregistrement de Gati-ncau.Avis est par la présente donné que le lot 5A-22 du rang VIT est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Canton de Labarre Cadastre officiel du canton de Labarre, municipalité de la cité d'Alma, division d'enregistrement du Lac Saint-Jean-est.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 36-5 du rang Saguenay est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 28 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-o.Canton d'Otis Cadastre officiel du canton d'Otis, municipalité du canton d'Otis, division d'enregistrement de Chicoutimi.Avis est par la présente donné que le bloc « H » est ajouté et qu'une partie des lots 44 à 47 du rang V et 46 et 47 du rang VI sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 3 juin 1974.5673 Township of Duhamel Official cadastre of the township of Duhamel, municipality of the village of Lorrainville, registration division of Témiscamingue.Notice is hereby given that lots 34-39 to 34-46, 34-58, 35-6 of range VI are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 17, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Township of Duhamel Official cadastre of the township of Duhamel, municipality of the village of Lorraineville, registration division of Témiscamingue.Notice is hereby given that lots 33-8 to 33-11, 33-13 to 33-18 and that a part of lot 33-12 of range VH are cancelled and integrated in lot 33-1 in virtue of articles 2174 and 2174a of the Civil Code.Québec, July 4, 1974.Benoît Ghimard, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Township of Hull Official cadastre of the township of Hull, municipality of the town of Touraine, registration division of Gatineau.Notice is hereby given that lot 5A-22 of range VII is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 25, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Township of Labarre Official cadastre of township of Labarre, municipality of the city of Alma, registration division of Lake Saint-Jean-east.Notice is hereby given that the remaining part of lot 36-5 of range Saguenay is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 28,1974.Benoît Grimard, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Township of Otis Official cadastre of township of Otis, municipality of township of Otis, registration division of Chicoutimi.Notice is hereby given that block \"H\" is added and that a part of lots 44 to 47 of range V and 46, 47 of range VI are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 3, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g. 5674 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, municipalité de la ville de Longueuil, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que le lot 141-691-1 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 18 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, municipalité de la ville de Longueuil, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que les lots 142-616-1.142-617-1 et qu'une partie des lots 142-615 à 142-618 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 juillet 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Edmond-de-Stoneham, municipalité des cantons unis de Stoneham et Tewkesbury, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 6-120 du rang II Stoneham est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 juillet 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Etienne-de-Lauzon Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Étienne-de-Lauzon, municipalité de Saint-Etienne*, division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné que le lot 199-4 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Henri-de-Mascouche Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Henri-de-Mas-couche, municipalité de la ville de Mascouche, division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que les lots 482-93 à 482-112 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 28 juin 1974.Parish of Saint-Antoine-de-Longueuil Official cadastre of the parish of Saint-Antoine-de-Longueuil, municipality of the town of Longueuil, regis-tion division of Chambly.Notice is hereby given that lot 141-691-1 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 18, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Antoine-de-Longueuil Official cadastre of the parish of Saint-Antoine-de-Longueuil, municipality of the town of Longueuil, registration division of Chambly.Notice is hereby given that lots 142-616-1, 142-617-1 and that a part of lots 142-615 to 142-618 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, July 15, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Edmond-de-Stoneham Official cadastre of the parish of Saint-Edmond-de-Stoneham, municipality of united townships of Stoneham and Tewkesbury, registration division of Québec.Notice is hereby given that a part of lot 6-120 of range II Stoneham is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, July 5, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Étienne-de-Lauzon Official cadastre of the parish of Saint-Étienne-de-Lauzon, municipality of Saint-Etienne*, registration division of Levis.Notice is hereby given that lot 199-4 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 25, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Henri-de-Mascouche Official cadastre of the parish of Saint-Henri-de-Mascouche, municipality of the town of Mascouche, registration division of L'Assomption.Notice is hereby given that lots 482-93 to 482-112 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 28, 1974.Benoît Grimrad, a.-g., 581 lO-o For the Deputy Minister.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année.n° 82 5675 Paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim-de-Châteauguay, municipalité de la ville de Château-guay-Centre, division d'enregistrement de Château-guay.Avis est par la présente donné que le lot 171-7 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 25 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joseph-de-Chambly, municipalité de la cité de Chambly, division d'enregistrement de Chambly.Avis est par la présente donné que le lot 267-10 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 11 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipalité de la ville de Blainville, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que le lot 768-20 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 juillet 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipalité de la ville de Blainville, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que le lot 767-96 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 5 juin 1974.Pour le sous-ministre, 58110-o Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Joachim-de-Châteauguay Officiai cadastre of the parish of Saint-Joachim-de-Chàteauguay, municipality of the town of Château-guay-Centre, registration division of Châteauguay.Notice is hereby given that lot 171-7 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 25, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Joseph-de-Chambly Official cadastre of the parish of Saint-Joseph-de-Cham-bly, municipality of the city of Chambly, registration division of Chambly.Notice is hereby given that lot 267-10 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 11, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville Official cadastre of the parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipality of the town of Blainville, registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lot 768-20 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, July 5, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy Minister.Parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville Official cadastre of the parish of Sainte-Thérèse-de-Blainville, municipality of the town of Blainville, registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lot 767-96 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, June 5, 1974.Benoît Grimard, a.-g., 58110-o For the Deputy M inister.Curatelle publique Succession Emile Fournier Succession de Emile Fournier.en son vivant de 4848 Cazelais, St-Henri, Montréal, Que., décédé le 28 octobre 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310 boul.St-Laurent.Montréal, Que.H2N 1N6 58097-o Public Curatorship Estate of Emile Fournier Estate of the late Emile Fournier, in his lifetime of 4848 Cazelais, St.Henri, Montreal, Que., deceased October 28th, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 58097-o 5676 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10.1974, Vol.106, No.32 Succession Claude Pelletier Succession de Pelletier, Claude, en son vivant de 1288, rue Piette, Juliette, Que., décédé le 26 août 1973.Le soussigné donne avis que sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (Chapitre 81 des lois du Québec 1971), il est administrateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal, Que.H2N 1N6 58104-o Estate of Claude Pelletier Estate of the late Pelletier, Claude, in his lifetime of 1288 Piette St., Joliette, Que., deceased August 26, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address mentioned below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal, Que.H2N 1N6 58104-o Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Revocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies\tDissolution\tGazette officielle No Name of the Companies\tDate\tOfficial Gatelte No.CENTRES CULTURELS POPULAIRES LE PATRIOTE INC.\t02 03 1974\t00 ST.MONIQUE AUTO PARTS INC.\t19 01 1974\t03 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies En conséquence.Iesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 58083-o Pierre Desjardins.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies, are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins, 58083-o Director of the Companies Service.Syndicats professionnels Professional Syndicates ASSOCIATION DES CADRES ET GERANTS DES COLLEGES DU QUÉBEC (A.C.G.C.Q.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 24 juillet 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « ASSOCIATION DES CADRES ET GERANTS DES COLLEGES DU QUEBEC (A.C.G.C.Q.) », avec siège social situé à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies eet coopératives, Albert Jessop.58117-0 1354-7005 ASSOCIATION DES CADRES ET GERANTS DES COLLEGES DU QUÉBEC (A.C.G.C.Q.) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on July 24, 1974, he authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"ASSOCIATION DES CADRES ET GERANTS DES COLLEGES DU QUEBEC (A.C.G.C.Q.)\", with head office located in Montréal, Judicial District of Montréal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58117 1354-7005 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 19?4, 106' aimée, n° S3 5677 SYNDICAT DES EMPLOYES COIFFEURS DU COMTE DE DRUMMOND INC.(Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 23 juillet 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DES EMPLOYES COIFFEURS DU COMTE DE DRUMMOND INC.», avec siège social situé au numéro 941, rue Rivard, Drummondville, district judiciaire de Drummond.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58116-0 1356-1741 SYNDICAT DES EMPLOYES COIFFEURS DU COMTE DE DRUMMOND INC.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on July 23, 1974, he authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT DES EMPLOYES COIFFEURS DU COMTE DE DRUMMOND INC.\", with head office located at number 941 Rivard Street, Drummondville, Judicial District of Drummond.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58116 1356-1741 Nomination Appointment Avis est donné que, par l'arrêté en conseil numéro 1310-74 du 10 avril 1974, il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer conseils en loi de la reine, par commission sous le grand sceau de la province, les avocats et membres du Barreau du Québec dont les noms suivent, savoir: Mattres Robert Bourassa, Paul E.Bisaillon, Michel Côté, Robert Dulude, L.Cameron DesBois, Paul F.Dingle, Monique Dubreuil, Tass Grivakes, David Kirshenblatt, Jean Monet, Herbert B.McNally, Jean-Marc Poulin, Gilles Y.Renaud, Maurice Régnier, Richard J.Riendeau.Donald W.Seal, J.Claude Thivier-ge, Clermont Vermette, Arthur A.Yanofsky, tous de Montréal; Henri LaRue, Louis Tardif, tous deux de Québec; Romuald Roy, Lucien Tremblay, tous deux de Chicoutimi; Blanka Gyulai, d'Outremont; Jean L.Dutil, de Thetford Mines; Louis Vaillancourt, de Verdun.Québec, le 29 juillet 1974.Le sous-procureur général adjoint, 58103-o René Langevin.Notice is given that, by Order in Council number 1310-74, dated April 10, 1974, it has pleased the Lieutenant-Governor in Council to appoint, by commission under the Great Seal of the Province, Queen's Counsel learned in the law, the advocates and members of the Bar of the Province of Québec whose names follow, to wit: Mes Robert Bourassa, Paul E.Bisaillon, Michel Côté, Robert Dulude, L.Cameion DesBois, Paul F.Dingle, Monique Dubreuil, Tass Grivakes, David Kirshenblatt, Jean Monet, Herbert B.McNally, Jean-Marc Poulin, Gilles Y.Renaud, Maurice Régnier, Richard J.Riendeau, Donald W.Seal, J.Claude Thivierge, Clermont Vermette.Arthur A.Yanofsky, all of Montreal; Henri LaRue, Louis Tardif, both of Québec City; Romuald Roy, Lucien Tremblay, both of Chicoutimi; Blanka Gyulai, of Outremont, Jean L.Dutil, of Thetford Mines; Louis Vaillancourt, of Verdun.Québec, July 29, 1974.René Langevin, 58103 Assistant Deputy Attorney General.Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for La commission scolaire de Sainte-Foy Siège social: 1000, rue Joli-Bois, Sainte-Foy, Québec.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Monsieur Aldège Sincennes, directeur général, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi.Bureau Administratif, 1000, rue Joli-Bois, Sainte-Foy, Québec, P.Q-, et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, Pavillon Technique, 1135, rue De Lavigerie, Sainte-Foy, Québec, P.Q., mardi, le 27 août 1974, pour l'achat de 8872,000 d'obligations de The Sainte-Foy School Board Head Office: 1000 Joli-Bois Street, Sainte-Foy, Québec.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mr.Aldège Sincennes, Director-General, until 4:30 o'clock p.m., at the Administration Office, 1000 Joli-Bois Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Pavilion Technique, 1135 De Lavigerie Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q., on Tuesday, August 27, 1974, for the purchase of a bond issue of 8872,000 for the Sainte-Foy School 5678 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 la commission scolaire de Sainte-Foy, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9J4%, ni supérieur à 10}^%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $872,000 \u2014 20 ans Date CapiUl 15 09 1975.$21,000 15 09 1976 .23,000 15 09 1977 .25,000 15 09 1978 .27,000 15 09 1979 .29,000 15 09 1980 .23,000 15 09 1981.25,000 15 09 1982.28,000 15 09 1983.30,000 15 09 1984 .34,000 La commission scolaire de Sainte-Foy se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $91,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 septembre 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Board, dated September 15, 1974, and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9J/2%, not more than W/2%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue ; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974.Redemption table \u2014 $872,000 \u2014 20 years Date CapiUl 15 09 1985.$37,000 15 09 1986 .41,000 15 09 1987 .45.000 15 09 1988 .50,000 15 09 1989 .56,000 15 09 1990 .61,000 15 09 1991.68,000 15 09 1992.75,000 15 09 1993.83,000 15 09 1994 .91,000 The Sainte-Foy School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Sututes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-ycar fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other paTt as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds will not be for an amount less than $91,000, and if greater than the latter amount, the said surplus must only comprise one or several complete annual redemptions, Uking into account the redemption Uble appearing in this notice, and sUrting with the last years of redemption excluding the maturity of September 14, 1994.However, tenders will be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exception stipulated herein.Adjudication will be made according to law. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n\" 32 5679 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles dont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $91,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation, au pair, le 15 septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission, conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire de Sainte-Foy s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 septembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 24 juillet 1959 \u2014 $38,500\u2014renouvellement d'emprunt; 28 mai 1974 \u2014 $1,500 \u2014 frais de refinancement; 28 mai 1974 \u2014 $832,000 \u2014 agrandissement de l'École élémentaire Marguerite Youville.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 27 août 1974, à 8.00 heures du soir.Pavillon Technique, 1135, rue De Lavigerie, Sainte-Foy, Québec, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sainte-Foy (Comté de Québec), ce 5 août 1974.Le directeur général, Aldège Sincennfs.Bureau Administratif, 1000, rue Joli-Bois, Sainte-Foy, Québec, P.Q.G1V 3Z6.Téléphone: 657-3366, code 418.58136-0 La commission scolaire d'Arvida Siège social: 346, boul.Mellon, CP.430, Arvida, (Chicoutimi), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Roch Laroche, directeur général.Bureau administratif, 346, boulevard Mellon, Case postale 430, Arvida, comté de Chicoutimi, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mardi, le 27 août 1974, pour l'achat de $341,000 d'obligations pour la commission scolaire d'Arvida, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1984 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9J^%, ni supérieur à W/2%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $91,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Sainte-Foy School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: July 24, 1959 \u2014 $38,500 \u2014 loan renewal; May 28, 1974 \u2014 $1,500 \u2014 refinancing costs; May 28, 1974 \u2014 $832,000 \u2014 extension of Marguerite Youville Elementary School.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, August 27, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Pavilion Technique, 1135 De Lavigerie Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Sainte-Foy (County of Québec), August 5, 1974.Aldègb Sincennes, Director-General.Administration Office, 1000 Joli-Bois Street, Sainte-Foy, Québec, P.Q.G1V 3Z6 Telephone: 657-3366, code 418.58136 The Arvida School Board Head Office: 346 Mellon Blvd., Post Office Box 430, Arvida, (Chicoutimi), P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Roch Laroche, Director-General at the Administrative Office, 346 Mellon Blvd., Post Office Box 430, Arvida, County of Chicoutimi, P.Q.until 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, August 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $341,000 for the Arvida School Board, dated September 15, 1974, and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1984 inclusive, with interest at a rate of not less than 9J4%.noi more than WA%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete 5680 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.82 doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour les fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $341,000\u2014 10 ans.Date Capital 15 09 1975.$21,000 15 09 1976.23,000 15 09 1977.26,000 15 09 1978.28,000 15 09 1979.31,000 La commission scolaire d'Arvida, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64) demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire d'Arvida s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 sep-tembie 1974, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu de la résolution datée du 28 mai 1974 \u2014 $341,000 \u2014 dépenses d'immobilisations de 1966-67 à 1972-73 inclusivement.Les soumissions seront ouveites et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui scia tenue à 7.30 heures du soir, mardi, le 27 août 1974, Bureau administratif, 346, boulevard Mellon, Case postale 430, Arvida, comté de Chicoutimi, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Arvida (Comté de Chicoutimi), ce 31 juillet 1974.Le directeur général, Roch Laroche.Bureau administratif 346, boulevard Mellon, Case postale 430.Arvida (Chicoutimi), Québec.Téléphone: 548-7181, code 418.58113-c annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974.Redemption table \u2014 $841,000 \u2014 10 years Date Capital 15 09 1980.$34,000 15 09 1981.38,000 15 09 1982.42,000 15 09 1983.47,000 15 09 1984.51,000 The Arvida School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication shall be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Arvida School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the resolution dated May 28, 1974 \u2014 $341,000 \u2014 capital expenditure from 1966-67 to 1972-73 inclusive.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesdav, August 27, 1974, at 7:30 o'clock p.m.at the Administrative Office, 346 Mellon Boulevard, Post Office Box 430, Arvida, County of Chicoutimi, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Arvida (County of Chicoutimi), July 31, 1974.Roch Laroche, Director-General.Administrative Office, 346 Mellon Blvd., Post Office Box 430, Arvida (Chicoutimi), P.Q.Telephone: 548-7181, code 418.58113 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 197/,, 106' année, n° S3 5681 Paroisse de St-Raphaël-de-l'îlc-Bizard Comté de Robert Baldwin Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné André Ranger, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 350, Montée de l'Église, Ile-Bizard, comté de Robert Baldwin, P.Q., jusqu'à 7.30 heures du soir, mardi, le 27 août 1974, pour l'achat de $922,000 d'obligations de la paroisse de St-Raphaël-de-l'île-Bizard, comté de Robert Baldwin, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9)/£%, n> supérieur à I0\\o%, payable semi-an-nuellcment les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $922,000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 15\t09\t1975.\t.S 8,000 15\t09\t1976.\t.9,000 15\t09\t1977.\t.10,000 15\t09\t1978.\t.11.000 15\t09\t1979.\t.13,000 15\t09\t1980.\t.15,000 15\t09\t1981.\t.17,000 15\t09\t1982.\t.19,000 15\t09\t1983.\t.21,000 15\t09\t1984.\t.21,000 En pl\tus.\tles modalités\tsuivantes seulement seront considérées :\t\t\t 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à tel me fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $63,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 septembre 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut Parish of Saint-Raphaël-dc-l'île-Bizard County of Robert Baldwin Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, André Ranger, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 350 Montée de l'Église, Île-Bizard, County of Robert Baldwin, P.Q., until 7:30 o'clock p.m., on Tuesday, August 27, 1974, for the purchase of a bond issue of $922,000 for the Parish of Saint-Raphaël-de-l'ÎIe-Bizard, County of Robert Baldwin, dated September 15, 1974, and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9J/£%, nor more than 10}^%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15,1974.Redemption table \u2014 S9S8.000 \u2014 20 years Date CapiUl 15 09 1985.$ 25,000 15 09 1986.27,000 15 09 1987.30,000 15 09 1988.33,000 15 09 1989.36,000 15 09 1990.38,000 15 09 1991.40,000 15 09 1992.43,000 15 09 1993.45,000 15 09 1994.461,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount'less than $63,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, Uking into account the redemption Ubles appearing in this notice, and sUrting with the last years of redemption, excluding the maturity of September 15, 2004 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of 5682 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 septembre 1994 au montant de $461,000 comprend un solde de $411,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date Capital 15 09 1995.$25,000 15 09 1996.27,000 15 09 1997.31,000 15 09 1998.34,000 15 09 1999.37,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $461,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de St-Raphaël-de-l'lle-Bizard s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 septembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements Nos: 103-A \u2014 $25,000 \u2014 voirie; 107 \u2014 $33,500 \u2014 aqueduc et égouts; 108 \u2014 $28,500 \u2014 aqueduc et égouts; 109 \u2014 $54,000 \u2014 aqueduc et égouts; 110 \u2014 $38,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et éclairage; 113 \u2014 $614,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et éclairage; 118 \u2014 $129,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et éclairage.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue à 7.30 heures du soir, mardi, le 27 août 1974, Hôtel de ville, 350, Montée de l'Église, Île-Bizard, comté de Robert Baldwin, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Ile-Bizard (Comté de Robert Baldwin), ce 31 juillet 1974.Le secrétaire-trésorier, André Ranger.Hôtel de ville, 350 Montée de l'Église, lle-Bizard, (Robert Baldwin), Québec.Téléphone: 626-5005, code 514.58100-o the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of September 15, 1994 in the amount of $461,000 included a balance of $411,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 09 2000.$41,000 15 09 2001.46,000 15 09 2002.51,000 15 09 2003.56,000 15 09 2004.63,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $461,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 15th of each for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of Saint-Raphaël-de-1'île-Bizard agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to Bylaws Nos.: 103-A \u2014 $25,000 \u2014 roads; 107 \u2014 $33,500 \u2014 waterworks and sewers; 108 \u2014 $28,500 \u2014 waterworks and sewers; 109 \u2014 $54,000 \u2014 waterworks and sewers; 110 \u2014 $38,000 \u2014 waterworks, sewers, roads and lighting; 113 \u2014 $614,000 \u2014 waterworks, sewers, roads and lighting; 118 \u2014 $129,000 \u2014 waterworks, sewers, roads and lighting.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Tuesday, August 27, 1974, at 7:30 o'clock p.m., at the Town Hall, 350 Montée de l'Église, Île-Bizard, County of Robert Baldwin, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.île Bizard (County of Robert Baldwin), July 31, 1974.André Ranger, Secretary-Treasurer.Town Hall, 350 Montée de l'Église, Île-Bizard, (Robert Baldwin), P.Q.Telephone: 626-5005, code 511.58100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106- année, n' 32 5683 Ville de Saint-Hubert Comté de Taillon Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Bernard Houle, greffier, Hotel de Ville, 7500 Chemin Chambly, Ville Saint-Hubert, comté de Taillon, P.Q., jusqu'à 5.00 heures de l'après-midi, et par après jusqu'à 8.00 heures du soir à la Salle des Assemblées du Conseil, 3350 Grande-Allée, Ville de Saint-Hubert, comté de Taillon, P.Q., lundi, le 26 août 1974, pour l'achat de 14,635,000 d'obligations pour la Ville de Saint-Hubert, comté de Taillon, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9}^%, ni supérieur à 10^2%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $4,635,000 \u2014 20 ans \tDate\tCapital 15\t09 1975.\t.$ 122,000 15\t09 1976.\t.134,000 15\t09 1977.\t.146,000 15\t09 1978.\t.162,000 15\t09 1979.\t.176,000 15\t09 1980.\t.140,000 15\t09 1981.\t.154,000 15\t09 1982.\t.169,000 15\t09 1983.\t.184,000 15\t09 1984.\t.202,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: Ie Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4e Obligations échéant en série là 10 ans avec Je solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations, échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $272,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 septembre 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.City of Saint-Hubert County of Taillon Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Bernard Houle, City Clerk, at the City Hall, 7500 Chambly Road, City of Saint-Hubert, County of Taillon, P.Q., until 5:00 o'clock p.m., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., in the Council Meeting Room, 3350, Grande-Allée, City of Saint-Hubert, County of Taillon, P.Q., on Monday, August 26, 1974, for the purchase of a bond issue of $4,635,000 for the City of Saint-Hubert, County of Taillon, dated September 15, 1974 and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%%< nor more than 10H%» payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974.Redemption table \u2014 $4,636,000 \u2014 20 years Date CapiUl 15 09 1985.$ 78,000 15 09 1986 .85,000 15 09 1987 .93,000 15 09 1988.101,000 15 09 1989.111,000 15 09 1990.121,000 15 09 1991.131,000 15 09 1992.142,000 15 09 1993.155,000 15 09 1994 .2,029,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the otheT part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $272,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and sUrting with the last years of redemption, excluding the maturity of September 15, 2004 of the renewable part hereinafter described. 5684 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Cependant, les soumsisions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 septembre 1994 au montant de $2,029,000 comprend un solde de $1,863,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of September 15, 1994 in the amount of $2,029,000 includes a balance of $1,863.000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 15 09 1995.$ 118,000 15 09 1996.130,000 15 09 1997.142,000 15 09 1998.156,000 15 09 1999.171,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $2,029,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Saint-Hubert s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 septembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: SH-23 \u2014 $105.000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie \u2014 SH-29 \u2014 $380,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; SH-30 \u2014 $700,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; SH-34 tel que modifié \u2014 $3,250,000 \u2014 aqueduc, égouts; 343 \u2014 $200,000 \u2014 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, lundi, le 26 août 1974, à 8.00 heures du soir.Salle des Assemblées du Conseil, 3350.Grande-Allée, ville de Saint-Hubert, comté de Taillon, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Hubert (comté de Taillon), ce 29 juillet 1974.Le greffier, Bernard Houle.Hôtel de Ville, 7500 Chemin Chambly, Ville de Saint-Hubert.Comté de Taillon, P.Q.Téléphone: 676-7744, code 514.58099-o Date Capital 15 09 2000.$ 189,000 15 09 2001.207,000 15 09 2002.228,000 15 09 2003 .250,000 15 09 2004 .272,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $2,029,000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Saint-Hubert agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: SH-23 \u2014 $105,000 \u2014 waterworks, sewers, roads \u2014 SH-29 \u2014 $380,000 \u2014 waterworks, sewers, roads \u2014 SH-30 \u2014 $700,000 \u2014 waterworks, sewers, roads \u2014 SH-34 as amended \u2014 $3,250,000 \u2014 waterworks, sewers \u2014 343 \u2014 8200,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting ot the Council or of one of its committees, as the case may be.to be held on Monday, August 26, 1974, at 8:00 o'clock p.m., in the Meeting Room, 3350 Grande-Allée, City of Saint-Hubert, County of Taillon, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Hubert (County of Taillon), July 29, 1974.Bernard Houle, City Clerk.City Hall, 7500 Chambly Road, City of Saint-Hubert, County of Taillon, P.Q.Telephone: 676-7744, code 514.58099 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n\" 32 5685 Ville de Saint-Antoine Comté de Prévost Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Jean Paul, greffier.Hôtel de ville, 854, boulevard Saint-Antoine, Ville de Saint-Antoine, comté de Prévost, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, lundi le 26 août 1974, pour l'achat de $362,000 d'obligations de la ville de Saint-Antoine, comté de Prévost, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9J4%, ni supérieur à \\0l/i%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $362,000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapiUl u\t09\t1975.\t.$ 9.000 15\t09\t1976.\t.9,000 15\t09\t1977.\t.10,000 15\t09\t1978.\t.10,000 15\t09\t1979.\t.12,000 15\t09\t1980.\t.13,000 15\t09\t1981.\t.14,000 15\t09\t1982.\t.15,000 15\t09\t1983.\t.16,000 15\t09\t1984.\t.18,000 En plus,\t\tles modalités\tsuivantes seulement seront considérées:\t\t\t 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporié à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montent inférieur à $34,000 et si supérieur à ce dernier montent, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du Ubleau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 septembre 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Town of Saint-Antoine County of Prévost Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Jean Paul, Town Clerk, at the Town Hall, 854 Saint-Antoine Boulevard, Town of Saint-Antoine, County of Prévost, P.Q., until 8:00 o'clock in the evening, on Monday, August 26, 1974, for the purchase of a bond issue of $362,000 for the Town of Saint-Antoine, County of Prévost, dated September 15, 1974, and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1994 inclusive, which interest at a rate of not less than 9J-£%, nor more than 10}/£%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue ; ho wever, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption Uble in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974.Redemption table \u2014 $362,000 \u2014 20 years Date Capital 15 09 1985.$16,000 15 09 1986.17,000 15 09 1987.18,000 15 09 1988.19,000 15 09 1989.22,000 15 09 1990.24,000 15 09 1991.26,000 15 09 1992.29,000 15 09 1993.31,000 15 09 1994.34,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $34,000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the Uble of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of September 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. 5686 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.82 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $34,000 et seul cet excédent sera rachetable par anticipation du pair le 15 septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Saint-Antoine s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 septembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 207 \u2014 $59,500 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 210 \u2014 $218,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 217 \u2014 $53,300 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 236 \u2014 $31,200 \u2014 honoraires professionnels.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8 heures du soir, lundi, le 26 août 1974, Hôtel de ville, 854, boulevard Saint-Antoine, Ville de Saint-Antoine, comté de Prévost, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Antoine (Comté de Prévost), ce 30 juillet 1974.Le greffier, Jean Paul.Hôtel de ville, 854, boulevard Saint-Antoine, Saint-Antoine, (Prévost), P.Q.Téléphone: 436-1762, code 514.58098-o Municipalité de Paspébiac Comté de Bonaventure Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Adéo-dat Gignac, secrétaire-trésorier.Salle municipale, Case postale 130, Paspébiac, comté de Bonaventure, P.Q., jusqu'à 8 heures du soir, mercredi, le 28 août 1974, pour l'achat de $110,000 d'obligations de la municipalité de Paspébiac, comté de Bonaventure, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9J-£%, ni supérieur à 10H%> payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $34,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Saint-Antoine agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.Said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 207 \u2014 $59,500 \u2014 waterworks, sewers and roads; 210 \u2014 $218,000 \u2014 waterworks sewers and roads; 217 \u2014 $53,300 \u2014 waterworks, sewers and roads; 236 \u2014 $31,200 \u2014 professional fees.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or one of its committees, as the case may be, at 8:00 o'clock in the evening, on Monday, August 26, 1974, at the Town Hall, 854 Saint-Antoine Boulevard, Town of Saint-Antoine, County of Prévost, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Antoine (County of Prévost), July 30, 1974.Jean Paul, Town Clerk.Town Hall, 854 Saint-Antoine Blvd., Saint-Antoine (Prévost), P.Q.Telephone: 436-1762, code 514.58098 Municipality of Paspébiac County of Bonaventure Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Adéodat Gignac, Secretary-Treasurer, at the Municipal Hall, Post Office Box 130, Paspébiac, County of Bonaventure, P.Q., until 8KK) o'clock p.m., on Wednesday, August 28, 1974, for the purchase of a bond issue of $110,000 for the Municipality of Paspébiac, County of Bonaventure, dated September 15, 1974 and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 9%}^, nor more than 10J^%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 19?4, 106' année, n° 32 5687 Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 SI 10,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 09 1975 .8 1,000 15 09 1976 .1,000 15 09 1977 .1,000 15 09 1978 .1,000 15 09 1979 .1,500 15 09 1980 .1,500 15 09 1981 .1,500 15 09 1982 .1,500 15 09 1983 .2,000 15 09 1984 .2,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec-le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 89,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 septembre 2004 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 15 septembre 1994 au montant de 869,500 comprend un solde de $65,500 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date CapiUl 15 09 1995 .$ 4,500 15 09 1996 .5,000 15 09 1997 .5,500 15 09 1998 .5,500 15 09 1999 .6,000 I,'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capiUl, plus les intérêU courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capiUl et les intérêU sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974.Redemption table \u2014 SI10,000 \u2014 20 years Date Capital 15 09 1985 .$ 2,000 15 09 1986 .2,500 15 09 1987 .2,500 15 09 1988 .2,500 15 09 1989 .3,000 15 09 1990 .3,000 15 09 1991 .3,500 15 09 1992 .3,500 15 09 1993 .4,000 15 09 1994 .69,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than 89,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, Uking into account the redemption Ubles appearing in this notice, and starting with the last years ot redemption, excluding the maturity of September 15, 2004 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the Urms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of September 15, 1994 in the amount of $69,500 includes a balance of $65,500 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date CapiUl 15 09 2000 .$ 6,500 15 09 2001 .7,000 15 09 2002 .8,000 15 09 2003 .8,500 15 09 2004 .9,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capiUl and any interest, by certified cheque.CapiUl and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure. 5688 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $69,500, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 septembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La municipalité de Paspébiac s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 septembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations-seront émises en vertu du règlement numéro 62 \u2014 $110,000 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue à 8 heures du soir, mercredi, le 28 août 1974, Salle municipale, Case postale 130, Paspébiac, comté de Bonaventure, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Paspébiac (Comté de Bonaventure), ce 2 août 1974.Le secrétaire-trésorier, Adéodat Gignac.Salle municipale.Case postale 130, Paspébiac (Bonaventure), P.Q.Téléphone: 752-5340, résidence, 752-2155 bureau, code 418.58134-0 Commission scolaire régionale de Grand-Portage Siège social: 464-A, Lafontaine, Rivière-du-Loup, C.P.460, comté de Rivière-du-Loup, Québec.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour Obligations » seront reçues par le soussigné Marc Bélanger, directeur-général, jusqu'à 5.00 heures de l'après-midi.Centre Administratif, 464-A, rue Lafontaine, C.P.460, Rivière-du-Loup, comté de Rivière-du-Loup, P.Q., et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, École Secondaire Saint-Pierre, 320 rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, comté de Rivière-du-Loup, P.Q., lundi, le 26 août 1974, pour l'achat de $483,500 d'obligations de la commission scolaire régionale du Grand-Portage, datées du 15 septembre 1974 et remboursables en série du 15 septembre 1975 au 15 septembre 1986 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 9^2%, ni supérieur à 10J-£%, payable semi-annuellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 septembre 1974.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $69,500 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on September 15th of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Municipality of Paspébiac agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 62 \u2014 $110,000 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held at 8.-00 o'clock p.m., on Wednesday, August 28, 1974, at the Municipal Hall, Post Office Box 130, Paspébiac, County of Bonaventure, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Paspébiac (County of Bonaventure), August 2, 1974.Adéodat Gignac, Secretary-Treasurer.Municipal Hall, Post Office Box 130, Paspébiac (Bonaventure), P.Q.Telephone: 752-5340, residence, 752-2155, office, code 418.58134 The Grand-Portage Regional School Board Head Office: 464-A, Lafontaine, Rivière-du-Loup, Post Office Box 460, County of Rivière-du-Loup, P.Q.Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Marc Bélanger, Director-General, at the Administrative Centre, 464-A Lafontaine Street, Post Office Box 460, Rivière-du-Loup, County of Rivière-du-Loup, P.Q.until 5:00 o'clock p.m., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Saint-Pierre Secondary School, 320 Saint-Pierre Street, Rivière-du-Loup, County of Rivière-du-Loup, P.Q., on Monday, August 26, 1974, for the purchase of a bond issue of $483,500 for the Grand-Portage Regional School Board, dated September 15, 1974 and redeemable serially from September 15, 1975 to September 15, 1986 inclusive, with interest at a rate of not less than 9^%, nor more than 10J^%, payable semiannually on March 15th and September 15th of each year.The rate of interest may bé the same for the whole issue however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from September 15, 1974. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n' 32 5689 Tableau d'amortissement \u2014 $483,500\u2014 12 ans Date Capital 15 09 1975.$ 9,000 15 09 1976.10,000 15 09 1977.11,000 15 09 1978.12,000 15 09 1979.13,000 15 09 1980 .52,500 La commission scolaire régionale du Grand-Portage, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64) demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La commission scolaire régionale du Grand-Portage s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans, les soixante jours à compter du 15 septembre 1974, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 29 avril 1968 \u2014 $339,000 \u2014 renouvellement d'emprunt: 3 juin 1974 \u2014 $13.500 \u2014 frais de refinancement: 3 juin 1974 \u2014 $131,000 \u2014 dépenses d'immobilisations 1972-1973.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue lundi, le 26 août 1974, à 8;00 heures du soir.École Secondaire Saint-Pierre, 320, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, comté de Rivière-du-Loup, P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Rivière-du-Loup (Comté de Rivière-du-Loup), ce 29 juillet 1974.Le directeur-général, Marc Bélanger.Centre Administratif, 464-A, rue Lafontaine, C.P.460, Rivière-du-Loup, Comté de Rivière-du-Loup, Québec.Téléphone: 862-8201, code 418.58101-o Redemption table \u2014 $483,600 \u2014 12 years Date Capital 15 09 1981 .$ 57,000 15 09 1982 .62,000 15 09 1983 .67,000 15 09 1984 .71,500 15 09 1985 .56,500 15 09 1986 .62,000 The Grand-Portage Regional School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Statutes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Grand-Portage Regional School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after September 15, 1974, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: April 29, 1968 \u2014 $339,000 \u2014 loan lenewal: June 3, 1974 \u2014 $13,500 \u2014 refinancing costs; June 3, 1974 \u2014 $131,000 \u2014 capital expenditure for 1972-1973.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Monday, August 26, 1974, at 8:00 o'clock p.m., at the Saint-Pierre Secondary School, 320 Saint-Pierre Street, Rivière-du-Loup, County of Rivière-du-Loup, P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Rivière-du-Loup (County of Rivière-du-Loup), July 29, 1974.Marc Bélanger, Director-General.Administrative Centre, 464-A Lafontaine Street, P.O.Box 460, Rivière-du-Loup, Countv of Rivière-du-1-oup, P.Q.Telephone : 862-8201, code 418.58101 5690 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.ABITIBI Fieri Fadas Canada \u2014 Province de Québec District d'Abitibi ( T 'OFFICE DU CREDIT AGRICOLE No 17,159a j-' DU QUEBEC, corps politique ayant ' son siège social à Québec, district de Québec, demandeur, m MARIUS VALLIÈRES, de Foleyet, dans la province d'Ontario, défendeur.« Le lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Palmarolle, sous le numéro dix-huit (18) du rang cinq (5) avec bâtisses et autres constructions y dessus érigées, circonstances et dépendances, et « Le lot connu et désigné aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour le canton Palmarolle sous le numéro dix-huit (18) du rang quatre (4).À distraire un emplacement de trois cent vingt-cinq pieds (325') de largeur par quatre cent cinquante pieds (450') de profondeur à prendre au coin nord-est dudit lot, cet emplacement se trouvant borné au nord par le chemin public, à l'est par le lot numéro dix-neuf dudit rang quatre, au sud et à l'ouest par la balance dudit lot dix-huit, cet emplacement est réservé avec bâtisses et autres constructions y dessus érigées, circonstances et dépendances.» Pour être vendu « en bloc » au bureau d'enregistrement au Palais de Justice d'Amos, le DIX-HUITIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à TROIS heures de l'après-midi.Le shirif.Bureau du Shérif, Laval Goulet.Amos, le 29 juillet 1974.58102-o JULIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( \"KULUDE TRANSPORT LIMITEE, No 799,043a corporation légalement constituée, l ayant son siège social et une place d'affaires dans la ville de St-Bruno, district de Montréal, demanderesse, M CLAUDE LACHANCE, résidant et Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.ABITIBI Fieri Facias Canada \u2014 Province of Québec District of Abitibi ( THE QUEBEC FARM CREDIT BU-No.17,159.4 1 REAU, body politic having its head v office in Québec City, District of Québec, plaintiff, vs MARIUS VALLIÈRES, of Foleyet, in the Province of Ontario, defendant.\"A lot known and described on the official plan and in the book of reference of the official cadastre for the Township of Palmarolle, under number eighteen (18) in Range five (5) with the buildings and other constructions erected thereon, appurtenances and dependencies, and «The lot known and described on the official plan and in the book of reference of the official cadastre for the Township of Palmarolle, under number eighteen (18) of Range four (4).Less and to withdraw an emplacement three hundred and twenty-five feet (325') in width by four hundred and fifty feet (450') in depth to be taken from the northeast corner of said lot; this emplacement is bounded on the north by the public road, on the east by lot number nineteen in said Range Four, on the south and on the west by the remainder of said lot eighteen; this emplacement is reserved with buildings and other constructions erected thereon, appurtenances and dependencies.* To be sold \"en bloc\" at the Registry Office in the Court House of Amos, on the EIGHTEENTH day of SEPTEMBER, 1974, at THREE o'clock in the afternoon.Laval Goulet, Sheriff's Office, Sheriff.Amos, July 29, 1974.58102 JOLIETTE Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal { \"T)ULUDE TRANSPORT LIMITEE, No.799,043a t a corporation legally incorporated, ' having its head office and its place of business in the Town of Saint-Bruno, District of Montreal, plaintiff, M CLAUDE LACHANCE, residing and GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année.n° 32 5691 domicilié au numéro 129 rue Archambault, à l'Assomption, district de Joliette, défendeur.a) « Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision cinquante-neuf du lot originaire numéro quatre cent trente-six (436-59) au cadastre officiel du Village de l'Assomption dont le propriétaire est Monsieur Claude Lachance, avec bâtisse y érigée portant le numéro civique 129 de la rue Archambault dans le village de l'Assomption, circonstances et dépendances ».6) « Une terre à bois connue et désignée aux plan et livre de renvoi officiels de St-Sulpice, comme faisant partie du lot numéro vingt-trois (P.23) contenant environ un arpent et demi de front sur sept arpents de profondeur, plus ou moins, bornée à un bout au nord-ouest, par les terres de L'Assomption, à l'autre bout au sud-est par Azellus de Grandpré, au nord-est par Albert Hétu ou représentant et du côté sud-ouest, partie par Ovide Hétu et partie par Émery Martel ou représentant, circonstances et dépendances ».c) « Un terrain situé en la paroisse de St-Gérard-de-Magella, comté de l'Assomption, connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro deux cent trente quatre (Ptie de 234) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de L'Assomption, mesurant cent pieds (100') de largeur sur toute la profondeur qu'il y a du chemin à aller jusqu'à la rivière, étant borné comme suit: en arrière par la rivière de l'Assomption; en front par le chemin public; d'un côté par l'emplacement appartenant à Monsieur Lemay ou représentant, puis de l'autre côté par celui appartenant à Monsieur Ludger Papin ou représentant.Le tout sans bâtisse, circonstances et dépendances ».d) « Un terrain situé en la paroisse de L'Epiphanie, connu et désigné comme faisant partie du lot originaire numéro cent vingt-trois (Ptie de 123) des plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de L'Epiphanie, mesurant cent cinquante pieds (150') de largeur sur le chemin public sur une profondeur de deux cents (200') plus ou moins, de plus une lisière de terrain de vingt pieds (20') de largeur du centre dudit emplacement et se prolongeant jusqu'à la rivière (étant un passage) borné comme suit: en front par le chemin public, en arrière par l'emplacement appartenant à Monsieur Chartier ou représentant pour partie, par la rivière et par une autre partie du même lot appartenant à Monsieur Fortin ou représentant pour l'autre partie; d'un côté par l'emplacement appartenant à Monsieur Bradeau ou représentant puis de l'autre côté par celui appartenant à Monsieur Parizeau ou représentant, sans bâtisse, circonstances et dépendances ».Pour être vendus au bureau de la division d'enregistrement de l'Assomption, à l'Assomption, 255 rue St-Etienne, district de Joliette.MARDI, le PREMIER jour d'OCTOBRE 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Le shérif-adjoint.Bureau du Shérif.Ginette Malo.Joliette, le 31 juillet 1974.58112-o domiciled at 129 Archambault Street, in L'Assomption District of Joliette, defendant.(a) \"An immoveable known and described as subdivision fifty-nine of original lot number four hundred and thirty-six (436-59) on the official cadastre for the Village of L'Assomption, whose owner is Mr.Claude Lachance, with a building erected thereon, bearing civic number 129 of Archambault Street in the Village of L'Assomption, appurtenances and dependencies\".(6) \"A woodlot known and described on the official plan and in the book of reference of Saint-Sulpice, as forming part of lot number twenty-three (Pt.23) measuring about one and a half arpents in front, by seven arpents in depth, more or less, bounded at one end on the northwest, by the land of L'Assomption, at the other end on the southeast by the property of Azellus de Grandpré, on the northeast by that of Albert Hétu or representative and on the southwest side partly by the property of Ovide Hétu and partly by that of Emery Martel or representative, appurtenances and dependencies\".(c) \"A piece of land located in the Parish of Saint-Gérard-de-Magella, County of L'Assomption, known and described as being part of original lot number two hundred and thirty-four (Pt.of 234) on the official plan and in the book of reference for the Parish of L'Assomption, measuring one hundred feet (100') in width by all the depth existing between the road and the river, and bounded as follows: in the rear by the L'Assomption River; in front by the public road; on one side by the emplacement belonging to Mr.Lemay or representative, and on the other side by the one belonging to Mr.Ludger Papin or representative.The whole without any buildings, appurtenances or dependencies\".(d) \"A piece of land located in the Parish of L'Epiphanie, known and described as forming part of original lot number one hundred and twenty-three (Pt.of 123) on the official plan and in the book of reference for the Parish of L'Epiphanie, measuring one hundred and fifty feet (150') in width on the public road by a depth of two hundred feet (200'), more or less, and a strip of land twenty feet (20') in width from the center of said emplacement and extending as far as the river (said strip being a passageway) bounded as follows: in front by the public road, in the rear by the emplacement belonging to Mr.Chartier or representative for the party, by the river and by another part of the same lot belonging to Mr.Fortin or representative for the other party; on one side by the emplacement belonging to Mr.Bradeau or representative and on the other side by the one belonging to Mr.Parizeau or representative, without any building, appurtenances or dependencies\".To be sold at the Division of L'Assomption Registry Office in L'Assomption, District of Joliette, on TUESDAY, the FIRST day of OCTOBER, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Ginette Malo, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Joliette, July 31, 1974.58112 5692 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District of Joliette ( PREMIER FIBER GLASS No 705-02-000350-74.< -C CONSTRUCTION INC., v corps politique et dûment constitué en corporation selon la loi, ayant son siège social et sa place d'affaires en les cité et district de Montréal, demanderesse, versus MICHEL DUCHARME, de la ville de Repentigny, district de Joliette, et y résidant au 9, rue Coutu.défendeur.« La subdivision numéro neuf du lot originaire numéro quinze (15-9) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Repentigny.» Pour être vendu au bureau de la division d'enregistrement de L'Assomption, à L'Assomption, 255, rue Saint-Etienne, district de Joliette, JEUDI, le TROISIÈME jour d'OCTOBRE 1974, à ONZE heures de la matinée.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, Ginette Malo.Joliette, le 31 juillet 1974.58111 MÉGANTIC Canada \u2014 Province de Québec District de Mégantic Cour Supérieure, ( TLTENRI SETLAKWE, domicilié No 6658.< et résidant au No 156 de la ' rue Notre-Dame Sud, Thetford Mines, district de Mégantic, demandeur, vs CLEMENT LECLERC, domicilié et résidant au No 357 de la rue Poulin, Thetford Mines, district de Mégantic.1.Les droits de surface seulement sur un terrain sis dans le quatrième rang du canton de Thetford, contenant une surface de trente arpents et demi (30.5) plus ou moins, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro dix-huit-A (Ptie 18-A) aux plau et livre de renvoi officiels du quatrième rang dudit canton de Thetford, dans le comté de Mégantic, mesurant mille sept cent vingt-sept pieds (1,727') de profondeur dans sa ligne nord-est qui longe le chemin public, mille trente et un pieds et huit dixièmes (1,031.8') de profondeur dans sa ligne sud-ouest qui longe le lot numéro dix-huit-B et huit cent quatre-vingt-dix pieds et six-dixièmes (890.6') de largeur dans sa ligne sud-est qui suit la ligne de division entre les quatrième et cinquième rangs du canton de Thetford, la ligne nord-ouest de ladite partie suivant le cours du ruisseau qui traverse ledit lot et ladite partie étant bornée à une extrémité, au sud-est, par la ligne de division entre les quatrième et cinquième rangs du canton de Thetford, à l'autre extrémité vers le nord-ouest par le ruisseau, d'un côté au nord-est par le chemin public, et de l'autre côté au sud-ouest par le lot numéro dix-huit-B; Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Joliette I PREMIER FIBER GLASS No.705-02-000350-74X * CONSTRUCTION INC., ' a body politic and corporate duly incorporated according to laws having its head office and place of business in the City and District of Montreal, plaintiff; versus MICHEL DUCHARME, of the City of Repentigny, District of Joliette, and therein residing at 9 Coutu Street, defendant.\"Subdivision number nine of original lot number fifteen (15-9) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Repentigny.\" To be sold at the L'Assomption Division Registration Office, in L'Assomption, 255 Saint-Étienne Street, District of Joliette.on THURSDAY, the THIRD day of OCTOBER, 1974, at ELEVEN o'clock in'the forenoon.Ginette Malo, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Joliette, July 31, 1974.58111-u MÉGANTIC Canada \u2014 Province of Québec District of Mégantic Superior Court, I TJTENRI SETLAKWE, domiciled No.6658.» and residing at number 156 I Nctre-Dame Street South, Thetford Mines, District of Mégantic, plaintiff, vs CLÉMENT LECLERC, domiciled and residing at number 357 Poulin Street, Thetford Mines, District of Mégantic, defendant.1.The surface rights only in a parcel of land situate on the fourth range of the Township of Thetford, con-t lining thirty acres and one half (30.5) in superficies, more or less, known and designated as being a part of lot number eighteen-A (Pt.No.18-A) on the official cadastre plan and in the book of reference for the fourth range of the said Township of Thetford, in the County of Megantic, measuring one thousand seven hundred and twenty-seven feet (1,727') in depth in its northeast line alongside the public road, one thousand and thirty-one feet and eight tenths of a foot (1,031.8') in depth in its southwest line alongside lot number eighteen-]] and eight hundred and ninety feet and six tenths of a foot (890.6') in width in its southeast line alongside the division line between the fourth and fifth ranges of the Township of Thetford, the northwest line of said part following the course of the stream that crosses said-lot and bounded at one end to the southeast by the division line between the fourth and fifth ranges of the Township of Thetford, at the other end to the northwest by the stream, on one side to the northeast by the public road, and on the other side to the southwest by lot number eighteen-B; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5693 2.Les droits de surface seulement sur un terrain sis dans le quatrième rang du canton de Thetford, contenant une surface de quinze centièmes d'arpent (0.15), plus ou moins, connu et désigné comme étant une partie du lot numéro dix-huit-B (Ptie No 18-B) aux» plan et livre de renvoi officiels du quatrième rang dudit canton de Thetford, dans le comté de Mégantic, mesurant cinquante pieds (50') de largeur dans sa ligne sud-est et trois cents pieds (300') de longueur dans la ligne nord-est qui longe le lot numéro dix-huil-A, la ligne sud-ouest de ladite partie suivant le cours du ruisseau qui passe sur ledit lot et ladite partie étant bornée au sud-est par une autre partie dudit lot numéro dix-huit-B appartenant à Arthur Nadeau ou ses représentants, au nord-est par le lot numéro dix-huit-A et au sud-ouest par le ruisseau, la ligne sud-est dudit terrain étant située à une distance de sept cent trente et un pieds et huit dixièmes (731.8') de la ligne de division entre les quatrième et cinquième rangs du caDton de Thetford ; 3.Les droits de surface seulement sur un terrain sis dans le cinquième rang du canton de Thetford, mesurant mille huit cent soixante-quatre pieds (1,864') de largeur sur un profondeur de neuf cent trente-cinq pieds (935') et contenant une surface de quarante arpents (40), plus ou moins, connu et désigné comme étant la partie nord-ouest des lots numéros un et deux de la subdivision du lot numéro dix-huit-A et comme étant la partie nord-ouest des lots numéros un et deux de la subdivision du lot numéro dix-huit-B (Ptie N.O.Nos 18-A-l, 18-A-2, 18-B-l et 18-B-2) aux plan et livre de renvoi officiels du cinquième rang dudit canton de Thetford, dans le comté de Mégantic, (moins et à distraire une lisière de cinquante pieds de largeur au nord-est dudit lot numéro un de la subdivision du lot numéro dix-huit-A 50' N.E.No 18-A-l) étant maintenant la propriété de Lynn, MacLeod Engineering Supplies Limited), ledit terrain étant borné comme suit: - à une extrémité, au nord-ouest, par la ligne de division entre les quatrième et cinquième rangs du canton de Thetford, à l'autre extrémité, au sud-est, par le reste desdits lots étant la propriété de Charles Auguste Demers, d'un côté au nord-est par la lisière nord-est de cinquante pieds de largeur distraite dudit lot numéro un de la subdivision du lot numéro six-huit-A et appartenant à Lynn, MacLeod Engineering Supplies Limited, et de l'autre coté, au sud-ouest, par le lot numéro un de la subdivision du lot numéro un de la subdivision du lot numéro dix-neuf-A; Tels que les biens immobiliers indiqués ci-dessus, les droits de surface desquels ont été vendus par Flintkote Mines Limited à Clément Leclerc, apparaissent tracés en rouge, sur un plan préparé par Benoit Allaire, arpenteur-géomètre du Québec, le dix-septième jour de juin, mil neuf cent soixante et onze (No 71-957), dont copie est annexée à l'acte de vente par Flintkote Mines Limited à Clément Leclerc, passé devant Me Jean-Marc Roberge, notaire, le deuxième jour de juin, mil neuf cent 2.The surface rights only in a parcel of land situate on the fourth range of the Township of Thetford.containing fifteen hundredths of an acre (0.15) in superficies, more or less, known and designated as being a part of lot Bumbei eighteen-B (Pt.No.18-B) on the official cadastral plan and in the book of reference for the fourth range of the said Township of Thetford, in the County of Mégantic, measuring fifty feet (50') in width in its southeast line and three hundred feet (300') in length in its northeast line alongside lot num-bei eighteen-A, the southwest line of said part following the course of the stream that passes on said lot and bounded to the southeast by another part of said lot number eighteen-B belonging to Arthur Nadeau or representatives, to the northeast by lot number eigh-teen-A and to the southwest by the stream, the southeast line of said parcel of land being at a distance of seven hundred and thirty-one feet and eight tenths of a foot (731.8') from the division Ime between the fourth and fifth ranges of the Township of Thetford; 3.The surface rights only in a parcel of land situate on the fifth range of the Township of Thetford, measuring one thousand eight hundred and sixty-four feet (1,864') in width by a depth of nine hundred and thirty-five feet (935') and containing forty acres (40) in superficies, more or less, known and designated as being the northwest part of lots numbers one and two of the subdivision of lot number eighteen-A and as being the northwest part of lots numbers one and two cf the subdivision of lot number eighteen-B (X.W.Pts.Nos.18-A-l.18-A-2, 18-B-l and 18-B-2) on the official cadastre plan and in the book of reference for the fifth range of the said Township of Thetford.in the County of Mégantic, (less and to he distracted the northeast fifty feet in width of said lot number one of the subdivision of lot number cighteen-A (N.E.50' No.18-A-l) being now the property of Lynn, MacLeod Engineering Supplies Limited), said parcel of land being bounded as follows: at one end to the northwest by the division line between the fourth and fifth ranges of the Township of Thetford at the other end to the southeast by the remainder of said lots being the property of Charles Auguste Demers.on one side to the northeast by northeast fifty feet in width of said lot number one of the subdivision of lot number eighteen-A belonging to Lynn, MacLeod Engineering Supplies Limited, and on the other side to the southwest by lot nuiul>er one of the subdivision of lot number nineteen-A; As the above immoveable properties, the surface rights of which have been sold by Flintkote Mines Limited unto Clément Leclerc, are shown outlined in red on a plan prepared by Benoit Allaire, Québec Land Surveyor, on the seventeenth day of June, one thousand nine hundred and seventy-one (No.71-957).a copy of which is annexed to the deed of sale by Flintkote Mines Limited unto Clément Leclerc executed before Me Jean-Marc Rol>erge, Notary, on the second day of 5694 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 soixante-douze, et enregistré au bureau d'enregistrement de Thetford, à Thetford Mines, le neuvième jour de juin, mil neuf cent soixante-douze, sous le numéro 66509.La présente cession est faite sujette à toutes les servitudes, actives et passives, apparentes et non-apparentes, pouvant grever ledit immeuble; en particulier, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, la présente cession est faite sujette à la servitude consentie par Flintkote Mines Limited en faveur de Adrien Nadeau.par acte reçu devant Me Jean-Marc Roberge, notaire, le vingt janvier mil neuf cent soixante-six et enregistrée à Thetford Mines le vingt-six janvier mil neuf cent soixante-six sous le numéro 51699, et par lequel était créée une servitude perpétuelle de droit de passage en faveur de la partie sud-est du lot numéro dix-huit-B (Ptie S.E.No 18-B) du quatrième rang du canton de Thetford appartenant à Adrien Nadeau ou représentants, lequel droit de passage devant servir à rejoindre le chemin public et affectant l'immeuble décrit ci-dessus au paragraphe 3 du titre désignation, ci-après appelé fonds servant.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Thetford à Thetford-Mines, le DOUZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Lallier.Thetford-Mines, ce 2 août 1974.58135 June, one thousand nine hundred and seventy-two and registered at the Office of the Registration Division of Thetford, at Thetford Mines, on the ninth day of June, one thousand nine hundred and seventy-two under number 66509.The present transfer is made subject to all active and passive apparent and unapparent servitudes that may encumber said immoveable; particularly, but without limiting the generality of the foregoing, the present transfer is made subject to the servitude granted by Flintkote Mines Limited in behalf of Adrien Nadeau, in a deed executed before Me Jean-Marc Roberge, notary, on the twentieth of January, one thousand nine hundred and sixty-six under number 51699, whereby there was created a perpetual right-of-way benefitting the southeast part of lot number eighteen-B (S.E.Pt.No.18-B) in Range Four of the Township of Thetford, belonging to Adrien Nadeau or representatives, which right-of-way shall be used to communicate with the public way and affecting the immoveable described herein in paragraph 3, under the heading \"Description\", herein referred to as the servient tenement.To be sold at the Registry Office in Thetford Mines, on the TWELFTH day of SEPTEMBER, 1974 at TEN o'clock in the fcrenoon.Jean-Louis Lallier, Sheriff's Office, Sheriff.Thetford-Mines, August 2, 1974.58135-o Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Mégantic ( T UCIEN LACROIX, rentier, résidant et No 6277.\\ ^ domicilié à Robertsonville, deman- l deur.vs WILFRID CHAMPAGNE, 253, Carreau, Thetford Mines, défendeur.L'immeuble suivant propriété du demandeur Lucien Lacroix.Un emplacement formant partie du lot 10A rang 6 du cadastre officiel pour le canton de Thetford, de la contenance de 50 pieds de largeur par 90 pieds de profondeur plus ou moins borné ledit emplacement en avant au chemin de front, à l'est au terrain de Louis Delisle ci-devant Louis Grenier, au sud au terrain de Arthur Perron ci-devant Joseph Roy, à l'ouest au terrain de Arthur Perron, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Pour être vendu au bureau d'enregistrement de la division de Thetford à Thetford Mines, le DOUZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à DIX heureset TRENTE minutes de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Jean-Louis Lallier.Thetford Mines, ce 2 août 1974.58132-0 Canada\u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Mégantic (J UCIEN LACROIX, annuitant, residing No.6277.-s and domiciled in Robertsonville, v plaintiff, vs WILFRID CHAMPAGNE, 253 Carreau, Thetford Mines, defendant.The following immoveable, property of the plaintiff, Lucien Lacroix.An emplacement forming part of lot 10A, Range 6, on the official cadastre for the Township of Thetford, measuring 50 feet in width by 90 feet in depth, more or less, said emplacement bounded in front by the fronting road, on the east by the piece of land belonging to Louis Delisle, formerly belonging to Louis Grenier, on the south by the land belonging to Arthur Perron, foimerly belonging to Joseph Roy, on the west by the land belonging to Arthur Perron, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.To be sold at the Thetford Division Registry Office in Thetford Mines, on the TWELFTH day of SEPTEMBER, 1974, at TEN-THIRTY o'clock in the forenoon.Jean-Louis Lallier, Sheriff's Office, Sheriff.Thetford Mines, August 2, 1974.58132 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106- année, n° 32 5695 MONTRÉAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal No 02-024 703-73 { (~MTE DE LACHINE, de-18-000 814-747X v-i manderesse, n CONLOB v.ENTERPRISES INC., défenderesse.« Un emplacement connu et désigné aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de Ville de Lachine, comme étant la subdivision cinquante-deux du lot deux cent vingt-trois (223-52) mesurant quarante pieds et dix-huit centièmes (40.18') en front, par quatre-vingt-quinze pieds (95') de profondeur; contenant une superficie de trois mille huit cent dix-sept pieds carrés et un dixième (3,817.1).» Pour être vendu au bureau du shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal.10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le ONZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 29 juillet 1974.58121-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A CAISSE POPULAIRE DE No 05-000252-73.< *-> STE-CECILE DE MONT-\\ REAL, corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 300 est, De Cas-telneau, ville et district de Montréal, demanderesse, vs MARIO DELLA SERRA, résidant et domicilié au 11,960, rue Lapierre, app.7, Montréal-Nord, et FIO-RINDO CORSO, résidant et domicilié au 8439, 8e avenue, St-Michel, district de Montréal, défendeurs.1) Ce certain emplacement sis en ladite cité de Montréal, ayant front rue Drolet, connu et désigné sous le No six cent quatre-vingt-quinze de la subdivision officielle du lot originaire No quinze (15-695) au cadastre officiel du Village Incorporé de St-Jean-Baptiste.Tel et ainsi que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes audit immeuble.2) Un emplacement sis en la cité de Montréal, ayant front sur la rue Drolet, connu et désigné sous le No six cent quatre-vingt-seize de la subdivision officielle du lot originaire No quinze (15-696) aux plan et livre de renvoi officiels du village St-Jean-Baptiste.Tel que le tout se trouve dans le moment, avec toutes servitudes actives et sujet à toutes servitudes passives s'y rattachant.Avec droit de passage en commun avec tous autres y ayant droit dans la ruelle sise en arrière dudit emplacement et tous autres droits y inhérents.MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District cf Montreal No.02-024 703-73 ( fMTY OF LACHINE, plain-18-000 844-747X ^ tiff, versus CONLOR EN-l TERPRISES INC., defendant.\"An emplacement known and described on the official plan and in the book of reference of the cadastre for the City of Lachine.as being subdivision fifty-two of lot two hundred and twenty-three (223-52) measuring forty and eighteen hundredths feet (40.18') in front, by a depth of ninety-five feet (95'); covering an area of three thousand eight hundred and seventeen and one tenth square feet (3,817.1).\" To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in the Citv of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56, on the ELEVENTH dav of SEPTEMBER, 1974, at ELEVEN o'clock in the foienoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, July 29, 1974 .58121 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montréal I T A CAISSE POPULAIRE DE No.05-000252-73.< A-' STE-CECILE DE MONT-l REAL, a legally constituted corporation having its principal place of business at 300 De Castelneau East, in the Citv and District of Montreal, plaintiff, vs MARIO DELLA SERRA, residing and domiciled at 11,960 Lapierre Street, Apt.7, Montreal-North, and FIORINDO CORSO, residing and domiciled at 8439 - 8th Avenue, Saint-Michel, District of Montreal, defendants.(1) That certain emplacement lying in said City of Montreal, fronting on Drolet Street, known and described as being lot number six hundred and ninety-five of the official subdivision of original lot number fifteen (15-695) on the official cadastre for the Incorporated Village of Saint-Jean-Baptiste.As the whole now subsists with all servitudes attaching to said immoveable.(2) An emplacement lying in said City of Montreal, fronting on Drolet Street, known and described as being lot number six hundred and ninety-six of the official subdivision of original lot number fifteen (15-696) on the official plan and in the book of reference for the Village of Saint-Jean-Baptiste.As the whole now subsists, with all active servitudes and subject to all passive servitudes attaching, thereto With a right of way in common with all others holding this right, in the lane located behind said emplacement, and all other rights attaching thereto. 5696 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 3) Ce certain emplacement sis en ladite cité de Montréal ayant front rue Drolet, connu et désigné sous le No six cent quatre-vingt-dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire No quinze (15-697) aux plan et livre de renvoi officiels du village St-Jean-Baptiste.Tel et ainsi que le tout se trouve actuellement avec toutes servitudes actives et sujet à toutes servitudes passives attachées audit emplacement.Lesdits immeubles portaient les numéros civiques 4472, 4474 et 4476 rue Drolet, à Montréal.Ces immeubles n'existent plus, ayant été démolis.Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le DOUZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974.à ONZE heures de l'avant-midi.Ces immeubles devant être vendus séparément.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, 31 juillet 1974.58130-o (3) That certain emplacement located in said City of Montreal fronting on Drolet Street, known and described under number six hundred and ninety-seven of the official subdivision of original lot number fifteen (15-697) on the official plan and in the book of reference for the Village of Saint-Jean-Baptiste.As the whole now subsists with all active servitudes and subject to all passive servitudes attaching to said immoveable.Said immoveables bore the civic numbers 4472, 4474 and 4476 Drolet Street, in Montreal.These immoveables no longer exist, having been demolished.To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House, in the City of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor.Room 56, on the TWELFTH day of SEPTEMBER.1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.These immoveables are to be sold separately.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, July 31, 1974.58130 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal { /\"MTÉ DE LACHINE, deman-No 02-042 269-73 A ^ deresse, vs ANTHONY 18-000 865-742.1 HEVESY, défenderesse.« Un terrain situé dans la cité de Lachine et composé de: a) Partie d'un lot connu et désigné au cadastre officiel de la paroisse de Lachine, sous le numéro deux cent soixante-seize subdivision du lot original huit cent quatre-vingt-sept, (887-Pt.276), de forme triangulaire, ayant front sur la rue Victoria, et mesurant soixante-quatorze pieds et quatre dixièmes de pied (74.4') dans sa ligne nord, cent pieds (100') dans sa ligne ouest et cent quinze pieds et soixante-dix-sept centièmes de pied dans sa ligne sud-est, borné en front au sud-est par la rue Victoria, d'un côté au nord par partie du lot 887-291 et par partie du lot 887-292 et de l'autre côté à l'ouest par une partie du lot 887-276.b) Partie d'un lot connu et désigné au susdit cadastre officiel sous le numéro cent quatre vingt-dix-neuf subdivision du lot original huit cent quatre-vingt-sept (887-Pt.199), de forme triangulaire, ayant front sur la rue Sir George Simpson, et mesurant quatre-vingt-quatorze pieds et un dixième de pied (94.1') dans sa ligne nord, cinquante-sept pieds et quatre dixièmes de pied (57.4') dans sa ligne sud-est, et cent dix pieds et deux dixièmes de pied (110.2') dans sa ligne sud-ouest le long de la rue Sir George Simpson, borné au sud-ouest par la rue Sir George Simpson, au nord par le Boulevard Métropolitain et vers le sud-est par le lot numéro 887-198 dudit cadastre.c) Le lot connu et désigné au susdit cadastre officiel sous le numéro deux cent un subdivision du lot original huit cent quatre-vingt-sept, (887-201).» Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal I C^TTY OF LACHINE, plain-No.02-042 269-73, < ^ tiff, vs ANTHONY HE-18-000 865-742.I VESY, defendant.\"A piece of land located in the City of Lachine and consisting of: (a) Part of a lot known and described on the official cadastre for the Parish of Lachine, under number two hundred and seventy-six, subdivision of original lot eight hundred and eighty-seven, (887-Pt.276), of triangular configuration, fronting on Victoria Street, and measuring seventy-four and four tenths feet, (74.4') on its north line, one hundred feet (100') on its west, line and one hundred and fifteen and seventy-seven hundredths feet, (115.77') on its southeast line, bounded in front on the southeast by Victoria Street, on one side on the north by part of lot 887-291 and by part of lot 887-292, and on the other side on the west by a part of lot 887-276.(6) Part of a lot known and described on the aforesaid official cadastre under number one hundred and ninety-nine, subdivision of original lot eight hundred and eighty-seven (887-Pt.199), of triangular configuration, fronting on Sir George Simpson, and measuring ninety-four and one tenth feet (94.1'), on its north line, fifty-seven and four tenths feet (57.4') on its southeast line, and one hundred and ten and two tenths feet (110.2') on its southwest line along Sir George Simpson Street, bounded on the southwest by Sir George Simpson Street, on the north by Metropolitan Boulevard and towards the southeast by lot number 887-198 on said cadastre.(c) The lot known and described on said official cadastre under number two hundred and one, subdivision of original lot eight hundred and eighty-seven, (887-201).\" GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 19U, 106' année, n' 32 5697 Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le DIXIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à ONZE heurse de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 29 juillet 1974.58131-0 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Provinciale \u2014 District de Montréal No 02-040317-73 ( \\/AL ROYAL BUILDING MA-18-000848-748-j v TERIALS LIMITED, de-l manderesse, rsO.P.S.CONSTRUCTION INC., défenderesse.« Un certain emplacement connu et désigné comme étant la subdivision deux cent soixante et onze du lot originaire vingt-quatre (24-271) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de Ste-Rose, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 6290 rue Rainville.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Laval, 155, Boul.Je Me Souviens, à Laval, P.Q.le DIXIÈME jour de SEPTEMBRE 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin Montréal, 29 juillet 1974.58122-o QUÉBEC Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: (TA COMPAGNIE D'AS-Cour Supérieure, ) *-> SURANCE VIE NORTH No 200-05-000718-74.1 AMERICAN LTEE corpora-\\ tion légalement constituée, avant une place d'affaires au 925, Chemin St-Louis, suite 30, Québec 6 contre GASTON BUSSIÈRES, domicilié et résidant à Charlesbourg, district de Québec et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« La redivision un de la subdivision dix-huit et la subdivision deux de la subdivision quinze du lot originaire sept cent quarante (740-18-1 et 740-15-2) aux plans et livres de renvoi du cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au Bureau d'enregistrement de Québec 116 rue St-Pierre, Québec, P.Q., le TREIZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif-adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 5 août 1974.58118-0 To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in the City of Montreal, 10 Craig Street East, Tenth Floor, Room 56, on the TENTH day of SEPTEMBER, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal.July 29, 1974.58131 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Provincial Court \u2014 District of Montreal No.02-040317-73 ( \\ 7AL ROYAL BUILDING MA-No.18-000848-748-v v TERIALS LIMITED, I plaintiff, tu O.P.S.CONSTRUCTION INC., defendant.\"A certain emplacement known and described as being subdivision two hundred and seventy-one of original lot twenty-four (24-271) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Ste.Rose, with a building erected thereon bearing civic number 6290 Rainville Street.\" To be sold at the Registry Office for the County of Laval, 115 Je me Souviens Boulevard, in Laval, P.Q., on the TENTH day of SEPTEMBER, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, July 29, 1974.58122 QUÉBEC F ieri Facias de Terris Québec, to wit: (\\TORTH AMERICAN Superior Court, J LIFE ASSURANCE No.200-05-000718-74.1 COMPANY LTD., a corpora-l tion legally incorporated, having its place of business at 925 St.Louis Road, suite 30, Québec 6, versus GASTON BUSSIÈRES, domiciled and residing in Charlesbourg, District of Québec, and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mis en cause.\"Redivision one of subdivision eighteen and subdivision two of subdivision fifteen of original lot seven hundred and forty (740-18-1 and 740-15-2) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division.With buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec City, P.Q., on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, August 5, 1974.58118 5698 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.32 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: /\"TES PLACEMENTS Cour Supérieure, ) J-' MARCHAND INC., No 200-05-001061-741.1 corporation ayant son siège ' social au 74, boulevard St-Joseph, Charlesbourg-Ouest, district de Québec vs, C.A.PARENT INC., corporation ayant son siège social au 2100, boulevard Père Lelièvre, Duberger, district de Québec.« Les lots 601-43 et 602-37 du cadastre de St-Am-broise-de-la-Jeune-Lorette, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116 rue St-Pierre, Québec, P.Q.le TREIZIÈME jour de SEPTEMBRE 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 5 août 1974.58120-o Fieri Facias de Terris Québec, to wit: (TES PLACEMENTS Superior Court, ) *-> MARCHAND INC., a No.200-05-001061-741.) corporation having its head ( office at 74 St.Joseph Boulevard, Charlesbourg West, District of Québec, vs, C.A.PARENT INC., a corporation having its head office at 2100 Père Lelièvre Boulevard, Duberger, District of Québec.\"Lots 601-43 and 602-37 on the cadastre for Saint-Am-broise-de-la-Jeune-Lorette, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 St.Pierre Street, Québec, P.Q., on the THIRTEENTH day of SEPTEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, August 5, 1974.58120 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( «THÉRÈSE LEMELIN, épouse Cour Supérieure,) ¦*- séparée de biens de YVES No 10-754.) LEMELIN, résidant et domiciliée { au 69, Des Pins Est, Québec, vs YVES LEMELIN, résidant et domicilié au 2150, 24e Rue, App.1, Québec, district de Québec.« Un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 304 des subdivisions du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-cinq (585-304) des plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour St-Roch Nord, de la cité de Québec, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le numéro civique 2150, 24e Rue, Québec.» Pour être vendu au Bureau du Shérif, au Palais de Justice, à Québec, le SEIZIÈME jour du mois de SEPTEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 5 août 1974.58119-0 Fieri Facias de Terris Québec, to wit:( 'T'HÉRÈSE LEMELIN, wife Superior Court, 1 *\u2022 separate as to property of YVES No.10-754.I LEMELIN, residing and domiciled at { 69 Des Pins East, Québec, vs YVES LEMELIN, residing and domiciled at 2150 - 24th Street, Apt.1, Québec, District of Québec.\"A piece of land known and described as being lot number 304 of the subdivisions of original lot number five hundred and eighty-five (585-304) on the plan and in the book of reference of the official cadastre for St.Roch North, in the City of Québec, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, bearing civic number 2150 - 24th Street, Québec.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the Court House of Québec, on the SIXTEENTH day of SEPTEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, August 5, 1974.58119 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5699 Errata Errata MS-783 1042-DYV-S-l Global Truck Leasing (Equipment) Ltd.Location Pelletier Enrg.Prendre note que dans l'avis mentionné en titre publié dans l'édition 30 du 27 juillet 1974, la décision rendue aurait dû être: « Désistement » au lieu de: « Rejetée».58084-o MS-783 1042-DYV-S-l Global Truck Leasing (Equipment) Ltd.Location Pelletier Enrg.Please note that in the notice under the above-mentioned title published in issue number 30, dated July 27, 1974, the decision rendered should have read: \"Withdrawal\" instead of: \"Rejected\".58084 MS-786 1124-DYV-S-l Gil-Flex Rental (Québec) Ltd.Prendre note que dans l'édition numéro 30 du 27 juillet 1974, à la page 5309, à la fin du 1er paragraphe la décision : « Rejetée » n'a pas été mentionnée.58084-o MS-786 1124-DYV-S-l Gil-Flex Rental (Québec) Ltd.Please note that in issue number 30, dated July 27, 1974, on page 5309, at the end of the first paragraph, the decision: \"Rejected\" was omitted.58084-o Domicile légal (Article 30)\tLegal domicile (Section 30) Nous aurions dû lire\tAu lieu de Edition No Page\t We ehould have read\tI nit fad of 24 4614 FORTUNA SPORTSWEAR LTD.FORTUNA SPORTSWEAR INC.68084-o 5700 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10.197!,, Vol.106, No.32 INDEX No 32 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES COOPERATIVE ASSOCIATIONS Association coopérative des artisans d'Amos (Formation).5672 WIS DIVERS MISCELLANEOUS NOTICES Centre d'études universitaires de Rimouski i.In nul.i.SS Estate of Denis Doyon (Benefit of Inventory).5665 Estate of Derek Brown (Benefit of Inventory).5666 Estate of Ernest Ashmele (Benefit of Inventory).5665 Estate of Philippe Corbeil (Benefit of Inventory).5664 Estate of Thérèse Bolduc (Benefit of Inventory).5664 Lake Megantic Pulp Company (Reduction-capital).5665 Succession Denis Doyon (Bénéfice d'inventaire).5665 Succession Derek Brown (Bénéfice d'inventaire).5666 Succession Ernest Ashmele (Bénéfice d'inventaire).5665 Succession de Philippe Corbeil (Bénéfice d'inventaire).5664 Succession Thérèse Bolduc (Bénéfice d'inventaire).5664 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Accordés: Granted: Arditi, Elliot Elias.5669 Aubin, Leopold.5669 Bolduc, Evelyne.5669 Bowen, Murray Boxenbaum.5669 Gélinas, Joseph Georges Germain.5669 Hrycko, Katherine Lynn.5669 Lavoie, Joseph Albert Marcel.5670 Richard, Joseph Léo Alfred.5670 Solomon, Catherine Ruth.5760 Demandes: Applications: Beauchamp, Louise.5667 Bergeron, Raymonde.5667 Cartier, Mary Margaret Géraldine.5666 Cauchon, Adrien.5666 Chalifoux, Maurice Richard.5667 Corbeil, Paul.5667 Côté, Joseph-Lucien-Terence.5668 Fernandez, Marchelline Joseph.5668 Lachance dit Lamarche, Gaétan.5668 Michel, Joseph, Roméo, Victor (dit Michel Villeneuve).5667 Tétreault, Francine.5668 Therrien, Jean-Guy.5668 Tremblay, Claudette Daigle.5668 CAISSES D'ÉPARGNE SAVINGS AND Avis de décisions rendues.5655 ET DE CRÉDIT CREDIT UNIONS Avis de décisions rendues (Errata).5699 Caisse d'économie des travailleurs de Granby Avis d'introduction de requêtes.5642 CaisL^d'économie Enoq (Mod.gr.).' '.I\"'.'.]'.5670 Notice \"proprio motu\" by the Commission 5654 Notice of decisions rendered.5655 COMMISSION COMMISSION Notice Df decisions rendered (Errata).5699 Commission Québec Transport Notice of submission of applications.5642 des transports du Québec Commission Avis de la Commission « proprio motu » 5654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n° 32 5701 COMPAGNIES EXTRA-PROVINCIAL ÉTRANGÈRES COMPANIES Permit: Licenses: GAC Private Brands Limited.5671 Loram Co.Ltd.5671 COMPAGNIES \u2014 COMPANIES LOI DES ACT Abandon Surrender de charte of Charter Association gaspésienne de protection des forêts, limitée (L').5619 Autobus de la Baie des Ha.Ha.inc.5619 Autodrome Gentilly inc.5619 Banara Investment Corp.5619 Bouble Knit Mfg.Corp.5619 Franco-American Fur Skins Ltd.5619 Gaspesian Forest Protective Association, Limited (The).5619 Gentilly Speedway Inc.5619 Grangette Rouge ltée (La).5619 Greenfield Park Donuts Ltd.5619 Keno limitée.5619 Norcanda Québec Limited.5619 Oeuvre des loisirs de Plessisville inc.(L').5619 Real Investment Corp.5620 Saykaly Agencies Ltd.5619 Société des infirmières visiteuses de Trois- Rivières et Cap-de-la-Madeleine inc.5619 Société d'habitation de St-Roch inc.5620 Administrateurs Directors (Article 84) (Section 84) Autos Bélanger Levis inc.5616 Bélanger Autos Levis Inc.5616 Bell Asbestos Mines, Ltd.5616 Canest Group Ltd.(The).5616 Chaussures Lewis limitée.; ¦ \u2022 \u2022.561(1 Club de baseball de Laval-des-Rapides inc.5616 Club de chasse et de pêche de la Pointe Magoon Inc.;.5616 Club de récréation du Manoir Thistle.5616 Cogemar Management Limited.5616 Domaine Marlboro inc.5616 Ersatz L.R.Inc.5616 Gestion Cogemar limitée.5616 Goupe Canest ltée (Le).5616 Labbé&filsïnc.5616 Lépineltée.5616 Lewis Shoes Limited.5616 Magoon Point Fish and Game Club Inc.5616 Meubles Radisson limitée (Les).5616 Place Desjardins inc.5616 Provigo inc.;.5616 Radisson Furniture Limited.5616 Restaurant Roma inc.5616 S.M.A.(Société de mathématiques appliquées) inc.5616 Thistle Manor Recreational Club.5616 Changement de nom Change of name Armoires et tapis Laferté ltée (Les).5617 Ascenseurs Nagle inc.5617 Ateliers électroniques de la Rive Sud inc.(Les).5617 Bravo Sweater Company Ltd.5617 Club de chasse et pêche Gallaher.5617 Compagnie du chandail Bravo ltée.5617 Corporation Fontel.5617 Entreprises Claucar inc.5617 Excavation Ricard inc.5617 Fermont inc.5617 Fontel Corporation.5617 Gallaher Fish and Game Club.5617 Garage R.Lachaine inc.5617 Granco Furniture Inc.5617 Hartolin Homes inc.5617 Maisons Hartolin inc.(Les).5617 Meubles Granco inc.(Les).5617 Nagle Elevator Co.Inc.5617 Placimad Inc.5617 Sautier inc.5617 Serena Québec.5617 Sialltée.5617 South Shore Electronic workshops Inc.5617 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Bédard (Eugène) inc.5621 Daily Pick-Up & Delivery Ltd.5620 Edifice Matteau inc____.;.5620 Hebrew Comsumptive Aid Association of Canada inc.5622 General Products Company.5622 Highmont Corporation Limited.5620 Immeubles Matteau limitée.5621 Investissements Brillant ltée (Les).5622 Klein &ShillerInc.5621 Larouche et Galipeau inc.5622 Micro-Doc Inc.5620 St-Yves Navigation inc.5622 Senopo Corporation Ltd.5621 Domicile légal (Article 30) Fortuna Sportswear Ltd.(Erratum) Legal domicile (Section 30) .5699 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) Part / A.B.C.Electronics Installations Inc.5609 Accueil du rivage inc.5609 Acier Kater ltée.5613 Adconex, société de gestion immobilière inc.5609 Aliments Roch ltée (Les).5609 Allerex Testing Centre Inc.5610 Allied Boat Company Canada Ltd.5609 Aménagement Huppe inc.5609 Aménagements Runo limitée (Les).5615 Andrew (Mark) Restaurant Inc.5609 5702 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1974, Vol.106, No.S3 Lettres patentes Letters Patent (1™ partie) (Part /) (suite) (continued) Approvisionnement Neptune inc.5609 Assurances Irving Gottheil inc.5612 Autobus Viens inc.5609 Bailey (Arthur) Corporation.5610 Baron Leather Products Inc.5614 Beauregard (Simon) inc.5609 Bijouteries W.Enslin inc.(Les).5611 Blondin & Poulin inc.5609 Boutique Pattes de Velours inc.5609 Cairgo (Canada) Inc.5609 Canadian Youth Student Sales Inc.5609 Candeco Limited.5609 Candeco limitée.5609 Captain's Wharf Restaurant Inc.(The)____ 5610 Carrosserie Perbeau ltée.5614 Cayouette (Claude) inc.5610 Centre de tests Allerex inc.(Le).5610 Centre du sport Mercier & Proulx ltée.5610 Chaussures Talbot (1974) inc.5610 Ciments de Kamouraska inc.(Les).5610 Clotraclnc.5610 Compagnie de construction Oakland ltée.5610 Compagnie de fabrication Cylindrix inc.5610 Compagnie de gestion immobilière Korfus ltée.5613 Compagnie de gestion Y.W.F.inc.5610 Compagnie des bateaux unis Canada ltée.5609 Construction Baillarge ltée.5610 Construction Belley & Lecavalier ltée.5610 Construction Claude Laplante incorporée.5610 Construction Elmo inc.5610 Construction F.Martel inc.5610 Construction Rabino ltée.5610 Construction Tesca inc.5615 Construction Tikor limitée.5615 Constructions Jannick inc.5610 Constructions Lavoie & Fils inc.(Les).5613 Constructions Maisons Rondes inc.5610 Corporation Arthur Bailey.5610 Corporation d'aménagement G.E.Carton ltée.5612 Cosmétiques Cinquante et Plus ltée (Les).5610 Créations Florales Cascade inc.5610 Cylindrix Mfg.Inc.5610 Delta Translations Inc.5611 Desrochers (Armand) inc.5611 Diamond Transport Inc.5611 Diesel Drapeau & Dubé inc.5611 Doucette (S.) et Fils inc.5611 Editions Lacombe inc.(Les).5611 Electrolec Inc.5611 Elmo Construction Inc.5610 Enslin (W.) Jewellers Inc.5611 Entreprises B.T.inc.(Les).5611 Entreprises Bruno Zocastello inc.(Les).5611 Entreprises C.F.N.P.inc.(Les).5611 Entreprises Del ltée (Les).5611 Entreprises Franlex inc.(Les).5612 Entreprises G.N.C.inc.(Les).5611 Entreprises G.O.C.inc.(Les).5611 Entreprises Jean & Jean ltée (Les).5611 Entreprises Lin limitée (Les).5611 Entreprises Ougiri inc.(Les).5611 Entreprises Prygo inc.(Les).5611 Entreprises Roger Laverdière inc.(Les).5611 Epicerie-Restaurant Desgagnés inc.5611 Etal Laurentien inc.(L').5611 Eurobel Imports Ltd.5612 Evaluations Ville-Marie inc.(Les).5611 Excavation Paul Ouimet inc.5614 Excavations Fontaine inc.5611 Fanning (J.A.) Investments Inc.5612 Farbec Inc.5612 Fer ornemental Jean-Guy Robert inc.5612 Ferme Quatre Soleils inc.(La).5612 Fifty Plus Cosmetics Ltd.5610 Fontaine Excavations Inc.5611 Four Suns Farm Inc.5612 Franlex Enterprises Inc.5612 G.E.Carton Development Corporation Ltd.5612 G.G.Buffing & Plating Inc.5614 G.N.C.Enterprises Inc.5611 Garage national St-Jean inc.5612 Germain (Claude) et Associés ltée.5612 Gestion Hégire inc.5612 Gestion Trans-Estrie inc.5612 Gestion TJltron limitée.5612 Glass Family Holdings Ltd.5614 Goodman (Philip) Inc.5612 Gottheil (Irving) Insurance Inc.5612 Grenada Realties Ltd.5612 Groupe de la cible ltée.5612 Groupe Miller ltée (Le).5613 Habitations Clomont inc.(Les).5612 Hamel (Jean) inc.5612 Hegire Holdings Inc.5612 Huppe Development Inc.5609 I.C.T.Tools Ltd.5614 Immeubles Grenada ltée (Les).5612 Immeubles Québec-Maritimes inc.5612 Immeubles Vignon inc.(Les).5612 Importations Eurobel ltée.5612 Importations Séoul inc.(Les).5615 Industries Bellechasse inc.(Les).5612 Industries de palettes universelles inc (Les).5613 Installations électroniques A.B.C.inc.(Les).5609 Institution Charlemagne inc.5613 Investissements Mildred inc.(Les).5613 Jacques (J.G.) inc.5613 Jannick Construction Inc.5610 Kamouraska Cernent Inc.5610 Kater Steel Ltd.5613 Korfus Realty Co.Ltd.5613 L.P.Leasing Inc.5613 Labarre (Roger) inc.5613 Lavoie & Sons Construction Inc.5613 Location L.P.inc.5613 location Ostiguy inc.5613 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106- année, n° 32 5703 Lettres patentes (Ire partie) (suite) Letters Patent (Part 1) (continued) Maison de peinture rue Ontario ltée.Maisons Syrisota limitée (Les).Manufacturier A.O.inc.Marché Baril inc.Marché N.Ouimette inc.Matouff Sports Inc.Megestal limitée.Mercier & Proulx Sport Center Ltd.Merter Inc.Mildred Investments Inc.Miller Group Ltd.(The).Mont St.Bruno Cleaners Inc.Montreal Aeronautics and Space Exhibition Inc.Nadeau (Marc H.) ltée.Navcom Inc.Nettoyeur Mont St-Bruno inc.Oakland Construction Company Ltd.Olympia Optical Ltd.Optique Olympia ltée.Ostiguy Rental Inc.Ouimet (Paul) Excavation Inc.Outilleurs Arpex inc.(Les).Outils I.C.T.ltée (Les).Pantique inc.Papeterie Sam inc.Paquet (Fernand) inc.Péli ltée.Pépinière Bourbeau inc.Perbeau Auto Body Ltd.Pharand Transport Inc.Placano Inc.Placements de la famille Glass ltée (Les)- Placements La Toscane ltée (Les).Placements J.A.Fanning inc.(Les).Plomberie Ouellet inc.Polissage & placage G.G.inc.Productions Pierre Dufresne inc.Produits de cuir Baron inc.(Les).Québec - Maritimes Realties Inc.Hal lino Construction Ltd.Rembourrages St-Romuald inc.Restaurant Je Reviens ltée.Restaurant Le Quai du Capitaine inc.(Le).Restaurant Mark Andrew inc.Roy & Racine inc.Runo Developments Limited.Salon de l'espace et de l'aéronautique de Montréal inc.Sam Stationery Inc.Seoul Imports Inc.Service et révocation Fournier de Sherbrooke incorporée.Services Mer-Pa inc.(Les).Shaaban Sportswear Inc.Sinamone Inc.Siparo Inc.Société de gestion Larobi inc.5613 5613 5613 5613 5613 5613 5613 5610 5613 5613 5613 5614 5615 5613 5613 5614 5610 5614 5614 5613 5614 5614 5614 5614 5615 5614 5614 5614 5614 5614 5614 5614 5614 5612 5614 5614 5614 5614 5612 5610 5614 5614 5610 5609 5614 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 5615 Société Dumel inc.(La).5615 Société F.R.inc.5615 Sovitalltée.5615 Sports Matouff inc.5613 Styro Sun Control Systems Inc.5615 Syrisota Homes Limited.5613 Système de contrôle solaire Styro inc.5613 Talbot Shoes (1974) Inc.5610 Target Group Ltd.5612 Tesca Construction Inc.5615 Tikor Construction Limited.5615 Traductions Delta inc.5611 Trans-Canada Sportswear Inc.5615 Transport Diamant inc.5611 Transport Pharand inc.5614 Tuscany Holdings Ltd.5614 Universal Palettes Industries Inc.5613 Variétés Deschênes inc.5615 Ventes de la jeunesse étudiante canadienne inc.(Les).5609 Ventilation C.A.S.(Mauricie) inc.5615 Vêtements de sport Shaaban inc.(Les).5615 Vêtements de sport Trans-Canada inc.(Les).5615 Viens Bus Inc.5609 Wilson (Laurent) inc.5615 Lettres patentes Letters Patent (3* partie) Port /// Association des Spartiates Molaoi de Montréal 5618 Cosemlnc.5618 Jeune Chambre de Ragueneau inc.5618 Ligue de baseball Midget des Cantons de l'Est me.5618 Molaoi Spartans Association of Montreal.5618 Réveil des aveugles de Granby inc.(Le).5618 Service de l'Aide aux couples inc.5618 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Centre pédiatrique Chateau Pierrefonds inc.5618 Cinevic Inc.5618 Corporation de l'Hôpital Champlain de Verdun (La).5618 Corporation Mermix (La).5619 Entreprises Workman inc.(Les).5618 Fournier (G.) ltée.5618 Maisons mobiles Métro ltée.5619 Metro Mobile Homes Ltd.5619 Mermix Corporation.5619 Pont Mercier Shopping Centre Inc.5619 Workman Enterprises Inc.5618 Siëge social Head office (Article 84) (Section 84) Ampak Limited.5623 Applied Research Products Ltd.5623 Black Lake Télédiffusion Inc.5623 Bois de construction M.Longpré inc.5623 Borec Inc.5623 Brownstein (David) Inc.5623 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, August 10, 1971,, Vol.106, No.82 5704 Siege social Head office (Article 84) (Section 84) (suite) (continued) Capitol Vending Co.Ltd.5623 Carabee Investments Ltd.5623 Casgrain & compagnie limitée.5623 Casgrain & Company Limited.5623 Centre psycho-pédagogique de Québec inc.5623 Charade Sportswear Ltd.5623 Clover Holdings Inc.5623 Creative Knitwear Ltd.5623 De Foy Construction Inc.5623 FM-AR Development Corp.5623 Hurtubise (Jacques) inc.5623 International Merchandising Corp.5623 Jardins St-Hubert inc.5623 Langsner-Fuhrer Inc.5623 Lemay Autobus ltée.5623 Longpré (M.) Lumber Inc.5623 Lou-ed Investments Co.Ltd.5624 Milano General Real Estate Inc.5624 Murray (Martin) Inc.5624 O'Gallagher & Associates Inc.5624 Penny-Lou Corporation.5624 Perreault-Mathieu & cie ltée.5624 Perreault-Mathieu & Co.Ltd.5624 Plaza d'enfants ltée.5624 Promotion & Investments Co.Ltd.5624 Promotion & placements cie ltée.5624 Provisions économiques ltée (Les).5624 S.P.Holdings Ltd.5624 Talbot (Alphonse) & fils inc.5624 Vendôme placements ltée.5624 Wait Realties Ltd.5624 Williams Construction Company Limited .5624 Winikoff Inc.5624 CURATELLE PUBLIC PUBLIQUE CURATORSHIP Avis de qualité: Notice of capacity: Fournier, Emile.5675 Pelletier, Claude.5676 DEMANDE À APPLICATION LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Corporation Ivanhoe (La).5624 Ivanhoe Corporation.5624 MINISTERE DEPARTMENT Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Bolton, canton-township.5672 Cap-de-la-Madeleine, par.5672 Como, village.5672 Duhamel, canton-township.5673 Duhamel, canton-township.5673 Hull, canton-township.5673 Labarre, canton-township.5673 Otis, canton-township.5673 Saint-Antoine-de-Longueuil, par.5674 Saint-Antoine-de-Longueuil, par.5674 Saint-Edmond-de-Stonham, par.5674 Saint-Étienne-de-Lauzon, par.5674 Saint-Henri-de-Mascouche.par.5674 Saint-Joachim-de-Châteauguay, par.5675 Saint-Joseph-de-Chambly.par.5675 Sainte-Thérèse-de-Blainville, par.5675 Sainte-Thérèse-de-Blainville, par.5675 NOMINATIONS APPOINTMENTS Conseil en loi Queen's Counsel de la reine: learned in the law Bisaillon.Paul E.5677 Bourassa, Robert.5677 Côté, Michel.5677 DesBois, L.Cameron.5677 Dingle, Paul F.5677 Dubreuil, Monique.5677 Dulude.Robert.5677 Dutil, Jean L.5677 Grivakes.Tass.5677 Gyulai.Blanka.5677 Kirshenblatt.David.5677 LaRue.Henri.5677 McNally.Herbert B.5677 Monet, Jean.5677 Poulin, Jean-Marc.5677 Régnier, Maurice.5677 Renaud.Gilles Y.5677 Riendeau, Richard J.5677 Rov, Romuald.5677 Sea'l, Donald W.5677 Tardif, Louis.5677 Thivierge, J.Claude.5677 Tremblay, Lucien.5677 Vaillancourt, Louis.5677 Vermette, Clermont.5677 Yanofsky, Arthur A.5677 «ENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATION ACT Révocation de dissolution: Revocation of dissolution: Centres culturels Populaires Le Patriote inc.5676 St.Monique Auto Parts Inc.5676 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Arvida, c.s.-s.b.5679 Grand-Portage, c.s.r.-r.s.b.5688 Paspébiac, munie.5686 Saint-Antoine, ville-town.5685 Sainte-Foy, c.s.-s.b.5677 Saint-Hubert, ville-city.5685 Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, par.5681 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 août 1974, 106' année, n\" 32 5705 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Association des cadres et gérants des collèges du Québec (A.C.G.C.Q.).5676 Syndicat des employés coiffeurs du comté de Drummond inc.5677 VENTES SALES Par Shérifs By Sheriffs Abitibi Abitibi Office du Crédit Agricole M Vallières.5690 Québec Farm Credit Bureau (The) vs Vallières 5690 Joliette Joliette Dulude Transport limitée vs Lachance.5690 Premier Fiber Glass Construction Inc.vs Ducharme.5692 Mégantic Mégantic Lacroix vs Champagne.5694 Setlakwe vs Leclerc.5692 Montréal Montreal Caisse populaire de Ste-Cécile de Montréal (La) vs Mario Delia Serra et al.5695 Lachine, cité-city vs Conlor Enterprises Inc.5695 Lachine, cité-city vs Hevesy.5696 Val Royal Building Materials Limited vs O.P.S.Construction Inc.5697 Québec Québec Compagnie d'assurance-vie North American ltée (La) vs Bussières.5697 Lemelin vs Lemelin.5698 North American Life Assurance Company Ltd.vs Bussières.5697 Placements Marchand Inc.(Les) vs Parent (C.A.) inc.5698 Taxes Taxes Pincourt, ville-town.5625 SOMMAIRE Associations cooperatives.5672 Avis divers.5664 Caisses d'épargne et de crédit.5670 Changement de nom, Loi dd.5666 Commission des transports du Québec 5640-5099 Compagnies, Avis concernant la Loi des.5609 5099 Compagnies étrangères.5671 Curatelle publique.5675 Demande a la Législature.5624 Ministère.5672 Nominations.5677 Renseignements sur les compagnies.5676 Soumissions.5677 Syndicats professionnels.5676 Ventes: Par shérifs.5690 Pour taxes.5625 SUMMARY Application to Legislature.5624 Appointments.5677 Change of Name Act.5666 Companies Act, Notices concerning the .5609 5099 Companies Information Act.5676 Cooperative Associations.5672 Department.5672 Extra-Provincial Companies Act.5671 Miscellaneous Notices.5664 Professional Syndicates.5676 Public Curatorship.5675 Québec Transport Commission.5640-5099 Sales: By Sheriffs.5690 For Taxes.5625 Savings and Credit Unions.5670 Tenders.5677 © nouveautés Ministère des Affaires sociales Régie des Rentes du Québec Rapport annuel 73/74 Régime des allocations familiales du Québec / Québec Family Allowances Plan Annual Report 73/74 Québec, 1974.32 p., 24 cm ISBN 0-7754-1854-4, broché S 1.00 Ministère de l'Industrie et du Commerce Taux de salaire et heures de travail, 1er octobre 1972 Québec, 1974.202 p.tabl.stat.28 cm, polycopié ISBN 0-7754-1865-X, broché $ 2.00 Ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives Rapport annuel 1973/74 / Annual Report Québec, 1974.242 p.24 cm ISBN 0-7754-1855-2, broché $ 3.00 Loi de la protection du consommateur (chapitre 74 des lois de 1971) et Règlement général /Consumer Protection Act (chapter 74 of the Statutes ot 1971) and General Regulation Québec.1974.82 p., 24 cm ISBN 0-7754-1856-0, broché S 1.25 Ministère des Richesses naturelles Direction générale des Eaux Études limnologiques des lacs: Des sables, Ech Manitou, Montagne noire.Sainte-Marie, Sain Joseph, Théodore Québec, 1973.144 p., tabl., cartes.28 cm ISBN 0-7754-1858-7, broché Planification de l'acquisition des données de qualité de l'eau au Québec Tome I \u2014 Relations entre l'utilisation de la ressource eau et sa qualité par P.G.Campbell, M.Meybeck et A.Tessier Québec.1974.94 p.tabl.graph.28 cm.polycopié ISBN 0-7754-1859-5, broché S 1.00 Tome 2 \u2014 Étude des phénomènes aquatiques REÇU LE 1 *i AOUT 197*» BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC Québec.1974.sous presse, polycopié ISBN 0-7754-1860-9, broché S 1.00 Tome 3 \u2014 Méthode d'acquisition des données de qualité utilisées dans différents pays Par A.Caillé, P.G.Campbell, P.Couture, M.P.Lamontagne, et J.-L.Sasseville Québec.1974.135 p., tabl.stat., graph., 28 cm, polycopié ISBN 0-7754-1861-7, broché S 1.00 Tome 4 \u2014 Utilisation du territoire d'un bassin et modèle d'apports Par D.Cluis, D.Couillard et L.Potvin Québec, 1974.135 p., tabl.stat., graph., 28 cm.polycopié ISBN 0-7754-1862-5, broché S 1.00 Tome 5 \u2014 Présentation de la méthode Par A.Caillé, P.G.Campbell, M.P.Lamontagne et J.-L.Sasseville Québec.1974.46 p., tabl.polycopié ISBN 0-7754-1863-3, broché S 1.00 Ministère des Transports Taux et tarifs sur le transport des écoliers pour l'année 1974-1975 (A.C.1693-74, modifié par A.C.2183-74) / Rates and Tariffs Respecting the Transport of Pupils for the Year 1974-1975 (O.C.1693-74, amended by O.C.2183-74) Québec, 1974.133 p.24 cm ISBN 0-7754-1852-8, broché S 2.00 S 5.00 Contient en pochette des cartes couleurs de chacun des lacs étudiés JL L'ÉDITEUR OFFICIEL \u2022 W DU QUÉBEC 675 EST, BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.