Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 2 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-11-02, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" t, GAZETTE QUEBEC ^EMBRE'974 m OFFICIELLE OFFICIAL OFF A11E8 G3/ PTIE1 EX.3 DU QUEBEC GAZETTE PARTIE 1 PART 1 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre MA, 106' année, n° U 8153 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS (VUS8 g, , 1 I.Prière d'adresser aux bons soins de l'Editeur officiel r\\->j2 * du Québec, Québec, toute communication d'avis desti-E*»1.née à la Gazelle officielle du Québec.f 2.La Gazelle officielle du Québec est composée de l* deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et contient des avis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Quebec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazelle.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.¦S.La Gazette officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 8154 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 197A, Vol.106, No.U TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, $20: du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25.1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Quebec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971,, 106' année, n° U 8155 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Compagnies \u2014 Loi des Companies Act Administrateurs Directors Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs whose names follow have changed the number of their directors tel qu'indiqué ci-après.as indicated hereinafter.\tDate de\tNombre d'administrateurs \tconstitution\tNumber of directors Nom de la compagnie\t\t Name of company\tDate of\tAncien nombre Nouveau nombre \tincorporation\tPrevious number New number A RCA M INC.24 10 72 725794 COMPAGNIE PHARMACO-CHIMIQUE, INC.19 09 57 CHEMICO-PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.12589-57 CYLINDRIX MFG.CO.INC.07 06 74 COMPAGNIE DE FABRICATION CYLINDRIX INC.1368-5748 INDUSTRIES P.H.L.INC.31 07 74 1358-2051 LE MOULIN BLANC INC.08 07 58 THE WHITE MILL INC.12230-58 MUJE INC.26 02 73 730786 MULTIDICK INC.21 06 73 737464 P.L.U.S.DESIGN INC.26 07 74 DESSIN P.L.U.S.INC.1358-1111 PARE & GRAHAM INC.25 03 74 1355-2237 LES PLACEMENTS LA TOSCANE LTEE.17 06 74 TUSCANY HOLDINGS LTD.1357-2714 QUEBEC MACK INC.02 03 59 11154-59 SERVICES DE LUBRIFIANTS INDUSTRIELS & 05 03 71 COMMERCIAUX (SLIC) INC.1164-71 SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE 29 07 74 FLEURY.PERRON 4 ASSOCIES LTEE 1368-9906 VEILLETTE INC.23 02 72 721060 5 4 3 4 3 4 5 4 4 58868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Debjardins.58868-q Pierre Desjardin», Director of the Companies Service. 8156 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 Domicile légal (Article 30) Legal domicile (Section 30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose names follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Préviens address New address ABATTOIRS SAINT-BASILE INC.19 08 74 Saint-Basile.116, rue Ste-Anne, Saint- 1358-6540 Basile.ABERFORD SPORTING CLUB.20 05 1898 Boholtz Lake.Boholtz Lake.C.C.P.5-1898 ACCESSOIRES ET OUTILLAGE D'AUTOS 21 04 64 Joliette.479, rue Baby, Joliette.BABY INC.BABY AUTO PARTS INC.1351-64 ACCESSORY EMBROIDERY INC.08 04 54 Montréal.9800, rue Clark, Montréal, 10780-54 ADELA REALTY LTD.17 08 55 Montreal.5086 Sax Street, Montreal.12203-55 ADRIA TRAVEL SERVICE INC.29 11 71 Montreal.4159St.Lawrence, AGENCE DE VOYAGE ADRIA INC.Montreal.716557 AETNA FACTORS CORPORATION LTD.01 02 56 Montreal.400 de Maisonneuve 10105-55 Boulevard Weat, Montreal.AETNA FACTORS CORPORATION LTD.01 02 66 400 de Maisonneuve 1246 Sherbrooke Btreet 10105-55 Boulevard West, West, Montreal.Montreal.AETNA FACTORS CORPORATION LTD.01 02 55 1246 Sherbrooke Street 1600 Atwater Avenue, 10105-55 West, Montreal.Montreal.A\u201e9EN>AS pARK-KING INC.11 03 68 10, rue 8t-Jacques, 8618, rue Henri-Julien, 10Ee°cyAL0IS & FILS INC03 11 72 Trois-Rivières.325, rue Chanoine Denon- ,-5883 court, Trois-Rivières.hA«RSST VEILLEUX LTEE.07 06 74 Montréal.5965.23e Avenue.1358-1285 Montréal.7K4jfiRA °IL LTD14 10 71 Montréal.6955, boulevard St-Michel, 715446 Montréal.VnÏÏÎ24wAS?ïï^B8INC- O»01™»- 09 12 71 500.Place d'Armes.1203, Edifice IBM, 5, Place 716853 chambre 1200.Montréal.Ville-Marie.Montréal.ISM?EfiRIE DESMARAIS LTEE.0« 12 61 882.rue Galt est.Sher- 888, rue Galt est.Sher- 0001 01 brooke.brooke.WLcKCV LIS ,,R0DUCER 10 06 68 MOntf&J \"l^e^rt 1 2755-68 Boulevard, Montreal.1008^ MANUFACTUR1NG C°- LTD12 01 60 Montréal3250.boulevard Métro- politain est, Montréal.WALTSON PROPERTIES (QUEBEC) LTD.02 04 71 Montréal.9300, rue Côte de Liesse.Montréal.WHITEROCK INDUSTRIES LTD.,5 01 7.416 St.James Street West, 555 Dorchester Boulevard °^ Montreal.West.Suito 1510, Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8171 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address WOODMORE DEVELOPMENT LTD.02 02 AMENAGEMENT WOODMORE LTEE 736273\t73 11940, avenue Grenet, 1420, rue Sherbrooke ouest, app.203, Montréal.suite 601, Montréal.Le directeur du service des compagnies, 58868-0 Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins.58868-0 Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivants:\tThe Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date LES AMIS DES ECOLES CHRETIENNES D'EGYPTE 1419-69 CENTRE DE THEATRE LAURENTIEN.et sa version anglaise LAURENTIAN THEATRE CENTRE 1356-7540 JACQUES CHARETTE ET ASSOCIES LTEE .et sa version anglaise JACQUES CHARETTE AND ASSOCIATES LTD.930-70 LE CLUB DAWSON POUR GARÇONS ET FILLES et sa version anglaise THE DAWSON BOYS' AND GIRLS' CLUB 8283-52 COLDOR INC.4508-69 LA COMPAGNIE DES VENTES LORRAINE LTEE.et sa version anglaise LORRAINE SALES COMPANY LTD.11395-58 LES DISQUES T.B.LIMITEE.723957 FOURNITURES ELECTRIQUES FORD LTEE et sa version anglaise FORD ELECTRIC SUPPLY LTD.1109-6973 LE FOYER DU FRIOUL INC.1367-6291 LES INVESTISSEMENTS COMPAS DU QUEBEC LTEE et sa version anglaise COMPASS INVESTMENTS OF QUEBEC LTD.737-64 ASSOCIATION CHRETIENNE DE LA HAUTE- 27 03 69 EGYPTE POUR LES ECOLES ET LA PROMOTION SOCIALE.LAURENTIAN THEATRE COMPANY.17 05 74 COMPAGNIE DE THEATRE LAURENTIEN J.E.CHARETTE DESIGNERS INC.02 03 70 THE DAWSON BOYS' CLUB.14 06 52 COLDOR CHINCHILLA RANCH INC.24 09 69 ROSS OFFICE SUPPLIES LTD.06 06 58 LES DISQUES AMPLI LTEE.13 07 72 FORD ELECTRIC SUPPLY LTD.26 08 59 CLUB FOLKLORIQUE FURLAN DE 03 01 74 MONTREAL INC.FURLAN FOLKLORIC CLUB OF MONTREAL INC.RIFA INC.14 02 64 8172 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 Nouveau nom / New name OFFSET VILLE MARIE INC.211-67 REFRIGERATION, PLOMBERIE & CHAUFFAGE LONGUEUIL INC.et sa version anglaise LONGUEUIL REFRIGERATION.PLUMBING & HEATING INC.1622-70 SALON DU DECOR DU SAGUENAY INC.734169 SERIGRAPHIE PLANETAIRE INC.et sa version anglaise PLANETARIUM SILK SCREEN INC.722309 SERVICO LIMITEE et sa version anglaise SERVICO LIMITED.5398-66 SUPER MARCHE VICTORIA INC.et sa version anglaise VICTORIA SUPER MARKET INC.1101-2598 THERMATIC LTEE.et sa version anglaise THERMATIC LTD.11494-56 Ancien nom Former name Incorporation Date 02 67 POLYCOPIE ABC INC.13 ABC DUPLICATING INC.LONGUEUIL REFRIGERATION INC.14 04 70 JEAN-PAUL FILLION INC.21 09 73 PREVOST SILK SCREEN (1973) INC.01 SERIGRAPHIE PREVOST (1972) INC.05 72 SERVICO LIMITED.17 10 66 VICTORIA SUPER MARKET INC.22 12 68 THERMATIC HEATING LTD.09 05 56 58868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.SS80S-o Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service.Fusion de compagnies Amalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Name of new corwpany\tSiège social Head office\tFusion Amalgamation Date\tNom des compagnies fusionnées Names of companies amalgamated LA CORPORATION DRAPERIES MONTREAL and its English version: MONTREAL DRAPERIES CORP.1358-3877\t55, rue Louvain ouest, Montréal.\t04 01 74\tMONTREAL DRAPERIES INC.HALLMARK DRAPERY CORP.PUBLICATIONS DU NORD-OUEST INC.1359-4783\t\t\tIMPRIMERIE LEBONFON LIMITEE {LEBONFON PRINTING LIMITED) L'ECHO ABITIBIEN LIMITEE THE VAL D'OR STAR LIMITED.68868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb.5S868-0 Pierre Debjardins, Director of the Companies Servies, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8173 Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a accepte l'abandon de la charte de: panies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date BIBLIO-HACHF.TTF.INC.13399-60 YVES BOUCHARD INC.724299 BOULANGERIE MORRISSETTE INC.4222-70 BOUTIQUE HARRIETTE INC.2838-65 CENTRE D'ENSEIGNEMENT INTENSIF DE LANGUES (MONTREAL) INC.INTENSIVE LANGUAGE TEACHING CENTER (MONTREAL) INC.1434-71 DOUCET AUTO-MOBILES INC.12964-55 FALC-RICH INC.5498-64 INDUSTRIAL CONCRETE FLOOR FINISHING CO.LTD.12468-62 05 08 60 02 08 72 28 09 70 17 06 65 01 04 71 08 11 55 19 12 63 07 06 62 01 11 74 01 11 74 01 11 74 01 11 74 29 10 74 28 10 74 25 10 74 01 11 74 Le directeur du service des compagnies, 58868-o Pierre Desjardinb.\tPierre Desjardins, 588C8-o Director of the Companies Service.Siege social (Article 84)\tHead office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci-après.\tNotice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed their head office as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address AGENCES SHERWOOD INC.28 07 71 541, 9e Avenue, Laval____ 317, rue Varry, Saint- SHERWOOD AGENCIES INC.Laurent.3930-71 09 09 70 Outremont.4190 Courtrai Avenue, Montreal.ALBERT SALES INC.LES VENTES ALBERT INC.3924-70 ALMA AUTOMOBILE LTEE.28 07 52 Saint-Joseph-d'Alma.200, rue Du Pont sud, 10532-52 Alma.ANTAGON CONSTRUCTION COMPANY LTD.12 11 58 Montréal.7050.Côte St-François, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION Saint-Laurent.ANTAGON LTEE 13968-58 S174 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November -2, 1974, Vol.106, No.44 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie-\u2014 Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address ARTO INC.16 09 58 Montréal.1100, rue Muir, 12992-58 Saint-Laurent.ASSOCIATION CHEVALINE PEPITE D'OR .24 02 71 Victoriaville.Route rurale No 3, 902-71 Warwick.LES ASSURANCES CLAUDE LAFRENIERE INC.27 08 70 21, rue Bousquet, 10, rue Louis-Baiinet.3717-70 Joliette.Saint-Charles-Borromée.BARRETTE & SAUCIER LTEE.12 08 69 Lebel-sur-Quévillon.Comtois.3871-69 BEAUDI INC.24 03 71 Sainte-Foy.50.Place Crémaiie ouest, 1342-71 suite 507, Montréal.BEIQUE & SHERRY INC.30 09 65 Montréal.2340, chemin Lucerne, 4330-65 suite 20.Mont-Royal.BEIiOL LTD.19 10 48 Montréal.105.rue René Philippe, BEROL LTEE Lemoyne.6605-48 BOIS FRANC P.N.D.LTEE.09 07 73 818, rue Moiart, Beloeil.132.rue De Nantes, 737583 Sainte-Julie.J.B.BRAULT HOLDINGS INC.16 03 62 Montréal.1071, rue Sylvestre, 10643-62 LaSalle.LE BUREAU DE TRADUCTION TRANS- 13 03 67 12220.rue Poutrincourt.5675.rue Pellan, ADAPT INC.Montréal.Brossard.1085-67 CANADA CHROME FURNITURE LTD.22 09 53 12, rue de la Reine, 1675.rue St-Denis, 41091-53 Sorel.Tracy.CAPITOL AUTOMOBILE INC.02 01 70 4005 Jean Talon Street 2475 Stevens Street.9-70 East, Montreal.Saint-Laurent.LE CERCLE DES FEMMES JOURNALISTES 26 10 51 Montréal.1330, rue Elisabeth, INCORPORE.Saint-Laurent.12322-61 F.CHAMPOUX LTEE.19 01 61 95.avenue Bigaoucttc, 2580.rue Plaia, 10300-61 Québec.suite 605, Sillery.CHIBOUGAMAU MINING & SMELTING 27 11 53 Montréal.Chibougamau.CO.INC.49199-63 A.B.CLARKE LIMITED.22 05 64 Montreal.2900 Francis-Hughes, A.B.CLARKE LIMITEE Chomedey, Laval.2345-64 CLUB D'ESCALADE DE L'ESTRIE INC.20 08 71 Drummondville.60, Place Crémaiie 714367 suite 700, Montréal.CLUB NATURISTE ADAM ,v EVE LTEE.11 12 72 5311, rue Sherbrooke ouest.Sainte-Brigittc-des-Saults 729571 app.416, Montréal.CLUB DES PIONNIERS DU MONT STE-ANNE 06 08 69 48, avonuo Roynlo.4855, 2e Avenue ouest, INC.Saint-Féréol-les-Nelgcs.Charlesbouri.3662-69 8 LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ETEX 02 03 65 Montréal.131 Spring Grove Crescent LTEE Outremont ETEX CONSTRUCTION COMPANY LTD.831-65 LA COMPAGNIE DE VETEMENTS J.G.LTEE 08 03 73 50.Place Crémaiie.Granby Plaia Shopping 731°43 Montréal.Centre, Granby. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, no 44 8175 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie - Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address LES CONSEILS REGIONAUX DE DEVELOP- 28 01 PEMENT ASSOCIES DU QUEBEC INC.(C.R.D.A.Q.) 384-71 CONSTRUCTION BELAND INC.02 09 3687-70 COURTIER PROVINCIAL EN ALIMENTATION 13 12 (1971) INC.PROVINCIAL FOOD BROKER (1971) INC.716979 CROWN OFFSET LTD.14 11 TYPOGRAPHIE COURONNE LTEE 738719 CRYSTAL INSURANCE BROKERS INC.25 11 5006-63 DAFOMAX INC.20 01 264-70 DALLAIRE ET DALLAIRE LTEE.21 11 14694-62 DARCON INC.04 07 11989-57 DECOLOG INC.10 02 720769 DISMAT INC.15 03 863-66 LE DOMAINE SPORTIF CLAIRVAL, INC.28 07 3384-65 ROBERT DUBE LIMITEE.27 03 1063-67 LES ENTREPRISES ARMAND HOULE LTEE 22 12 16184-61 LES ENTREPRISES ESTEREL INC.21 05 2398-65 ERECTION BRETON LTEE.22 05 1368-3560 FREDETTE & MALOVIN TIRE SERVICE 05 12 INC.SERVICE DE PNEUS FREDETTE & MALOUIN INC.729524 FVRST PERMANENT MANAGEMENT LTD.29 09 LES GESTIONS PERMANENTES FURST LTEE 729072 G de D PLUMBING SUPPLIES INC.09 03 LES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE G & D INC.731081 GALLERY CONSTRUCTION INC.21 10 4392-70 GEMSCREEN ADVERTISING LTD.27 07 3262-67 71 Québec.2835, chemin Gomin.Sainte-Foy.70 Saint-Hyacinthe.Douville.71 Montréal.6665.rue Bombardier, Saint-Léonard 73 975 Brown Boulevard, Verdun.3810 St.Patrick Street.Montreal.63 Westmount.5725.Côte St-Luc, suite 112, Montréal.70 Montréal.2940, rue Lamarche, Saint-Hyacinthe.62 Giffard.905, rue Ducharme, Vanier.57 Sept-Iles.1794.rue Francheville, Montréal.72 5605, rue Amos, 2206.rue du Richer, Montréal-Nord.Laval.66 49, boulevard Stinton, 1295, rue Newton, Saint-Laurent.Boucherville.65 Boulevard Talbot.110, rue Racine est, Laterrière.Chicoutimi.67 Beloeil.19, rue Plante, Mont Saint-Hilaire.61 Route rurale numéro 2, Victoriaville.65 269, rue Principale ouest, Magog.123, rue Arbour, Neufchâtel.1.rue Pleasant, Ayer's Cliff.64 Montréal.Montréal-Nord.72 4620.Viterbe, Saint-Léonard .72 500 Place d'Armes, Suite 1200, Montreal.73 5637 Merrimac Street, Côte Saint-Luc.70 3137 Brighton Avenue.Montreal.67 9200 Park Avenue.Montreal.6661 est, rue Sherbrooke.Montréal.28 Frankelin Avenue, Mount Royal.2900 Rosemont, Montreal.197 Finchley Road, Hampstead.430 Deslauriers Street, Saint-Laurent. 8176 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Siège social Head office Date Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse A'etc address GENOA GENERAL REAL ESTATE INC.4280-67 LES IMMEUBLES BALTA LTEE BALTA REALTIES LTD.1368-8726 IMPRIMERIE TRANSCONTINENTALE INC.TRANSCONTINENTAL PRINTING INC.736636 LES INDUSTRIES R.& L.GIRARD INC.4725-70 INSTRUMENTS DE MUSIQUE P.A.LIMITEE P.A.MUSICAL INSTRUMENTS LIMITED 733189 INTER-AMERICAN TEXTILE CORP.14660-62 12 10 67 03 07 74 21 03 73 THE JUNIOR LEAGUE OF MONTREAL INC.5905-40 KAVANAGH AUTOMOBILES LTEE 5786-68 KENNEBEC HOMES INC.6808-64 KORVETTE STORES LTD.LES MAGASINS KORVETTE LTEE 13638-58 LABELLE TOURISTAIR INC.10674-55 LAURENTIDES DISCOUNT HOUSING INC.1711-70 LEEDS SALES LTD.14447-61 SIMON LUSSIER LTEE 15594-60 M & M MERCHANDISING AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.6822-69 MAPLE LEAF HEIGHTS INC.11616-59 MAXEL HOLDINGS LTD.12623-57 McGILL AUTO PARK INC.2413-63 METRO OIL INC.HUILE METRO INC.2588-65 A.MEUNIER TRANSPORT INC.10076-59 AIME MEUNIER INC.4258-69 1 Place Laval, app.330, Laval.1 Place Ville-Marie.Suite 3635, Montreal.524, rue Stanstead, Mont-Royal.19 11 70 Trois-Rivières 13 07 73 311, rue Beaubien est, Montréal.20 11 62 20 11 40 20 12 68 18 12 64 30 10 58 23 04 55 17 04 70 12 09 61 15 12 60 23 11 69 4696 Carlton Avenue, Montreal.Montreal .Montebello Montréal .200, Place 21 Mars, Nicolet.159.rue Craig ouest, Montréal.Lava).Montreal.Montréal 1255 University Street, Montreal.8255 St.Lawrence Boulevard, Montreal.76 Desjardins Street, Sainte-Agathe-des-Monts.433, boulevard Lebeau, Saint-Laurent.1360, 53e Rue, Shawinigan.7487, 18e Avenue, Saint-Michel.5807 Elridge Street, Côte Saint-Luc.366 Victoria Avenue, Westmount.10472, rue Tolhurst, Montréal.130, rue de Poitiers, Sainte-Julie.2325, boulevard des Récollets, Trois-Rivières.8670-A, boulevard des Mille-Isles, Laval.6830.boulevard Pelletier, Brossard.7071 Côte St.Luc, Côte Saint-Luc.129, Montée du Moulin, Laval.48 Holtham Place, Hampstead.24 03 69 Montréal.809, rue Deslauriers, Saint-Laurent.06 09 57 Montréal.6764, rue Westluke, Côte Saint-Luc.03 06 63 Montreal.45 St.Joseph Street.Lachine.04 06 65 Lachine.136.avenue Strathearn, Montréal-Ouest.07 01 59 Montréal.6395 boulevard Louis- Hippolyte-Lafontaine.Anjou.MODERN TEAK HOUSE DECOR INC.716498 27, rue Gauthier, Laval.27 11 71 Montreal.Saint-Laurent.03 09 69 759.rue Roland Forget.Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, no 44 8177 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adress New address MOTEL RENDEZ-VOUS DU LAC INC.3728-66 MULTIPLE BUSINESS FORMS LTD.LES FORMULES COMMERCIALES MULTIPLES LTEE 4259-67 NARLENCO SURPLUS JOBBERS LTD.722697 15 09 66 Sainte-Adèle.445.rue Yvon Berger, Laval.31 10 67 Montréal.9553, Côte-de-Liesse, Dorval.17 05 72 Shannon.ORZECH, BRADY 4 COMPANY LTD.716642 PANORAMA CERAMICS INC.723342 PAQUETTE & FRERE, LTEE 1619-68 PARAMOUNT TRANSPORT LTD.13754-56 PARC MILLE-ISLES INC.5709-69 PAUL & EDDY INC.16026-61 PLACEMENTS M.G.B.INC.M.G.B.INVESTMENTS INC.3611-68 PONT MERCIER SHOPPING CENTRE MERCHANTS' ASSOCIATION INC.15628-61 PORTLAND REALTY INC.15573-52 QUINCAILLERIE MAURICE HAMEL & FILS INC.726341 RENE REFRESHMENT SERVICE INC.12855-61 LOUIS ANDRE ROBERT LTEE.1368-0053 S.T.O.P.3356-70 ST.LAWRENCE TANKERS LIMITED 2395-30 ST.LUC VETS TAXI INC.12976-58 SAMIV LTEE.734748 SOCIETE DE FORMULES MECANOGRAPHIQUES INC.INTEGRATED BUSINESS FORMS INC.11165-62 02 12 71 13250 Acadie Boulevard, Pierrefonds.13 06 72 1440 Towers Street, Suite 102, Montreal.5258, rue Bourbonnière.Montréal.2150 De Maisonneuve Boulevard, Montreal.66 Alie Street, Dollard-des-Ormeaux.16 04 63 Saint-Michel.8282, rue Guyenne, Saint-Léonard.07 12 56 Montreal.10325 Ryan Avenue.Dorval.10 12 69 Montreal.712 Caven Circle, Saint-Laurent.02 02 62 Sainte-Scholastique.271.boulevard Sauvé.Saint-Eustache.14 08 68 Ue-Perrot.7-A.rue Champagne, ValleyBeld.14 12 61 414 LaFleur Boulevard, 5075 Sorel Street, LaSalle.Montreal.12 11 52 Montréal 28 11 72 Québec .09 06 61 7954, rue Notre-Dame est, Montréal.30 04 74 5643, Côte-des-Neiges, Montréal.15 09 70 25 Roosevelt Avenue, No 8.Mount Royal 20 12 30 Québec.21 08 58 Côte Saint-Luc.30 10 73 20, rue Gaulin, Beauport.16 03 62 Montréal.SOMI INC.991-66 25 03 66 5528, lie Avenue, Montréal.1819, rue Glendale, Outremont.195, rue Principale, Sainte-Croix.6480, rue Des Roseraies.Anjou.1650, Dunkirk.Mont-Royal.2052 St.Catherine Street West, Montreal.345 Fortin Street.Vanier.3600, rue Hôtel-de-Ville, Montréal.907, boulevard Rochette, Sainte-Thérèse-de-Lisieux 189 St.Henri Street Drummondville.7502, rue Verdier, Saint-Léonard. 8178 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.U Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address SPANGAV MANAGEMENT LTD.16 04 68 Montreal.1%^Som?^ 1635-6S STYNE'S SHOE SHOP LTD.12 05 72 Montréal.21£in™ Lauren?.'8' STYRO-PLASTIC LTEE.01 10 69 Québec.2860.chemin des Quatre- STYRO-PLASTIC LTD.Bourgeois, Sa.nte-Foy.4769-69 SUPER MARCHE METHOT LTEE.30 10 69 Sainte-Thérèse.302.rue Molière, Laval.3169-69 PIERRE TARDIF INC.26 03 55 Québec.1122 Chemin St-Louis, 10810-55 S,llery- TEKA INC .01 10 68 9666, rue Péloquin, 3333, chemin du Souvenir, 4271-68 MontréaL Laval.TOP VALUE LTD .06 04 61 1010 St.Catherine Street 92 Wellington Street.11513-61 West, Suite 600.Hull.Montreal.LORENZO TURCOTTE INC.30 05 68 875, avenue Chapais, Abercorn 2455-68 Val-d'Or.UNITED SETTLEMENT SUPPLY CO.LTD.19 03 70 55, rue d'Auteuil.61.rue Olympia, 1248-70 Québec.Lacolle.VAL REFUSE DISPOSALS INC.24 11 69 Dorion.475, Terrasse de la 5609-69 Capricieuse, Laval.VIVAX (1973) INC.04 07 67 83, avenue Legrand, 5131, boulevard St- 2869-67 Laval.Laurent.Montréal.LES VOILIERS AUX QUATRE VENTS INC.07 07 72 280, rue Bullard, Magog.79, rue Court, Coaticook.723847 WESTMOUNT MOVING AND WAREHOUSING 31 05 29 5760, Côte-de-Liesse, 61.boulevard Hymus, LIMITED.Mont-Royal.Pointe-Claire.1089-29 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb, 58868-0 Pierre Desjardins.58868-0 Director of the Companies Service.Lettres patentes (Ire partie) Letters Patent (Part I) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I de la Loi des compagnies, il a accorde des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Incorporation ttom I Name Siege social / Head Office Date ACKREN LTEE.P.O.Box 947, Place Bonaventure, 12 08 74 and its English version Montreal.ACKREN LTD.1369-2983 ALIMENTS DES INDES OCCIDENTALES RAMDA8 LTEE .Montreal.12 09 74 and its English version RAMDAS WEST INDIAN FOODS LTD.1369-6372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 novembre 1974, 106' année, no 44 S179 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ALIMENTATION CLEMENT PARE INC .1358-7803 ALIMENTATION GILLES TREMBLAY INC 1359-0112 ALIMENTATION J.E.ROY INC.1359-5574 ALUMINIUM SIMARD & GUILLEMETTE INC.et sa version anglaise SIMARD & GUILLEMETTE ALUMINIUM INC.1369-9772 AMENAGEMENT CANTERBURY LTEE and its English version CANTERBURY DEVELOPMENT LTD.1369-4757 AMENAGEMENT CARALON INC .and its English version CARALON DEVELOPMENT INC.1369-4690 AMENAGEMENTS IMMOBILIERS M.W.Z.LTEE .and its English version M.W.Z.PROPERTY DEVELOPMENTS LTD.1369-8394 AMENAGEMENT MAGNUM INC.and its English version MAGNUM DEVELOPMENT INC.1359-3843 LES AMENAGEMENTS STE-ANNE-DES-MONTS INC.and its English version STE.ANNE-DES-MONTS DEVELOPMENT INC.1369-2777 AMENAGEMENT ST-ELZEAR INC.1359-0120 AMEUBLEMENT BEAUMONT INC.1358-6813 AMEUBLEMENT DU MANUFACTURIER BLAINVILLE INC.1369-8337 ROGER AMYOT INC.1359-1664 ANTIQUITES DE LA VIEILLE EUROPE INC.et sa version anglaise OLD EUROPE ANTIQUES INC.1359-1607 10572.rue Royale, Sainte-Anne-de- 30 09 74 Beaupré.Les Eboulements.06 09 74 2797, Turbide, Giflard.07 10 74 Saint-Constant.08 10 74 1420 Sherbrooke Street West.Suite 601, Montreal.27 08 74 5734 Lockwood Road, Côte Saint-Luc.27 08 74 5640 Westminster Avenue North.27 09 74 Côte Saint-Luc 5781, Palmer.Côte Saint-Luc.26 09 74 Montréal.08 08 74 Saint-Elzéar.880, Commerciale, Saint-David-de-L'Auberivière.454, 22e Avenue, Blainville.3804, 1ère Rue.Chomedey, Laval.1 Place Ville-Marie, suite 930, Montréal.20 09 74 21 07 74 27 09 74 18 09 74 16 09 74 ARCAMO INC 1369-6950 ARTICLES DE SPORTS LACOURSE INC.1368-7678 ARTISANAT LANEA INC.et sa version anglaise LANEA HANDICRAFT INC.1368-7660 L'ASSOCIATION DES CITOYENS DE LA RIVE-SUD.and its English version SOUTH SHORE CITIZENS ASSOCIATION 1357-6674 98, rue Pontmain, Laval-des-Rapides, 18 09 74 Laval.400, Grande-Côte, Boisbriand.19 06 74 175, rue Stillview, Pointe-Claire.19 06 74 3256, Grand-Boulevard, Saint-Hubert.05 06 74 8180 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 2.1974, Vol.106, No.44 Incorporation Nom / .VtM Siège social / Head Office _ Date ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE CHALETS DE Baie-Comeau.01 10 74 LA RIVIERE FRANQUELIN 1359-4759 L'ATELIER DU MEUBLE ANCIEN COCULET INC.Boulevard Edouard VII, Saint- 09 08 74 1369-2892 Philippe.AUTO REAL MENARD LTEE.2341, Rang St-Eusèbe, Saint-Félicien .19 09 74 et sa version anglaise REAL MENAS!) AUTO LTD.1359-2316 LES AUTOBUS G.D.INC.Saint-Eustache.07 10 74 1369-9491 LES AUTOBUS LAMOTHE & GAGNE INC.Bedford.27 08 74 1358-7977 BAR SALON LYNN, GHANBY INC.800, rue Principale, Granby.26 09 74 1359-40S0 BAR SALON MICHELINE, GRANBY INC.800.rue Principale, Granby.26 09 74 1359-4072 BATIMEX INC.Montréal.13 09 74 1359-1318 JOS.BELAND INC.7235, boulevard Monk, app.3.24 09 74 1369-4419 Montréal.A.BERGERON & ASSOCIES INC.143 - 20ème Avenue, Mistassini.10 09 74 1369-0542 BESNER ET LAMANQUE INC.Côteau-du-Lac.26 09 74 1369-7982 BIJOUTERIE M.BOLDUC INC.Sainte-Marie.12 09 74 1359-1086 BIJOUTERIE RICHELIEU INC.365.Place Laurier, Beloeil.09 10 74 et sa version anglaise RICHELIEU JEWELLERY INC.1359-5970 BONTEMPS & LEBLANC LTEE.Pointe-Gatineau.06 09 74 1359-0138 E369-699^ULANGER INC2050 Mansfield Avenue, Montreal.18 09 74 ?369°8691ASSA LTEE121, rue Principale, Shawbridge.30 09 74 BOURBONNAIS ET LEBLANC INC.Rimouski.I] 09 74 1367-4389 F3°69-™°>N ET F,LS ,NCSaint-Polycarp.25 09 74 B^vQeVsLLfngiEsGeARD INC60, rue Evangeline, Granby.03 08 74 LOOK BOUTIQUE INC.1358-2713 f369^669iUE M°DE JEUNE^E DE M0NTREAL LTEE2255.rue Fleury est.Montréal.06 09 74 SKEwS* VIRAGE ,NC6822 St.Hubert Street.Montreal.24 09 74 n^lE49IE PATELIN LTEE IP^V21e'Marie'SUite2315' 19 09 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1971, IOG' année, n° U 8181 Nom / Same Siège social / Head Office Incorporation Date BRASSERIE ST-PASCAL INC.1359-5418 BREVETS EURCOCAN LTEE and its English version EU ROC AN PATENTS LTD.1369-7503 CAFE GIGOLETTE INC.1369-2779 ROBERT CARON, CHAUSSURES INC.1357-9883 VENANT CARON MATANE LTEE.1359-2613 CAROSSERIE D'AUTOS C.J.INC.et sa version anglaise C.J.AUTO BODY INC.1368-9445 CARRIERE LANDREVILLE INC.1369-2621 CENTRE ARTISANAL DE L'ILE AUX COUDRES INC____ 1359-5202 CENTRE DU BRICOLEUR J.A.K.INC.1356-9124 CENTRE DU CAMION BEAUCE INC.1359-2803 CENTRE MUSICAL CHEZ DUKE INC.1369-3322 CENTRE DE RECHERCHE DU VIEUX MONTREAL SUR L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES 1368-8486 CENTRE SPORTIF WILSON INC.and its English version WILSON'S SPORTS CENTRE INC.1369-8295 CENTRE DE VETEMENTS EN GROS (QUEBEC) LIMITEE and its English version THE WHOLESALE CLOTHING CENTER (QUEBEC) LIMITED 1369-9624 MEDARD CHAPADOS INC.1355-6857 JEAN-PAUL CHARBONNEAU ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE 1359-2357 CINE SAHRET INC.1368-1648 CLAURI INC.1369-2092 LE CLUB DES MOTONEIGI8TES DU LAC WILLIAM INC.1369-1672 CLUB RECREATIF DES RESSORTISSANTS DE FROSOLONE 1369-5457 2086, rue Trinité, Québec.04 10 74 Suite 1010.615 Dorchester 23 09 74 Boulevard West, Montreal.Montréal.23 09 74 1380.rue Notre-Dame.Trois-Rivières.22 07 74 16.rue Gendron, Matane.23 09 74 100, 9ième Avenue nord, Sherbrooke.03 09 74 950.rue d'Anjou.Boucherville.23 09 74 La Baleine, Ile-aux-Coudres.04 10 74 90.rue Nelson, Kénogami.03 06 74 Route Kennedy, Beauceville-Est.24 09 74 312, boulevard Normandie nord,.25 09 74 Farnham.Montréal.02 07 74 6536, avenue Somerled, Montréal.27 09 74 COMAUVI INC.1369-1662 11825 Lachapelle Street, Montreal____ 08 10 74 Saint-Godefroi.08 04 74 2320, rue Laprade, Tracy.19 09 74 2015, rue Peel, 3e étage, Montréal.31 05 74 Rimouski.18 09 74 Route rurale numéro 1, Ireland.16 09 74 5114, 18e Avenue, Rosemont.04 09 74 Montréal.31 07 74 8182 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date COMPAGNIE MARITIME QUEBECOISE (C.M.Q.) LTEE.1369-9335 COMPAGNIE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE D.K.INC.et sa version anglaise D.K.PLUMBING AND HEATING INC.1369-8501 LA COMPAGNIE DE REFRIGERATION NORDIQUE INC.1359-5061 LA COMPAGNIE REGITAN LTEE.et sa version anglaise REGITAN COMPANY LTD.1359-3090 CONCARE INC.1369-9566 CONFECTION ALAPO INC.1358-7571 CONFECTION LEBLANC (1974) INC.1357-4249 F.CONSTANTINEAU & FILS INC.1359-2134 CONSTRUCTION ANAC LTEE.and its English version ANAC CONSTRUCTION LTD.1369-7339 CONSTRUCTIONS DOMICILIAIRES CHATEAUGUAY LTEE.and its English version CHATEAUGUAY DEVELOPMENT LTD.1369-7362 CONSTRUCTION GAPIANE INC.1359-5046 CONSTRUCTIONS LEBRUN & TREMBLAY INC.et sa version anglaise LEBRUN & TREMBLAY CONSTRUCTION INC.1358-9387 CONSTRUCTION MARETAL INC.et sa version anglaise MARETAL CONSTRUCTION INC.1369-3908 CONSTRUCTION QUANTA INC.et sa version anglaise QUANTA CONSTRUCTION INC.1369-7354 CONSTRUCTION ROLLAND PLANTE INC.1358-7217 Montréal.04 10 74 3310.Henri-Bourassa, Montréal.30 09 74 Saint-Louis-de-Terrcbonne.03 10 74 364 Montée de Liesse, Montréal.24 09 74 3033, De Ville, Montréal.07 10 74 366, rue Mayor, app.1006, Montréal.26 08 74 203, rue Hamel, Disraeli.10 09 74 18 09 74 23 09 74 1117, boulevard Paquette, Mont-Laurier.1010 ouest, rue Ste-Catherine, suite 1020, Montréal.582 - 90icme Avenue, Lasalle.6180, boulevard Couture, Saint-Léonard.1820, boulevard Manicouagan, Hauterive.23 09 74 03 10 74 03 09 74 CORPORATION D'ELECTRONIQUE SHEFFORD et sa version anglaise SHEFFORD ELECTRONICS CORPORATION 1370-0067 LA CORPORATION DE GESTION A.S.P.et sa version anglaise A.S.P.HOLDING CORPORATION 1357-4439 CORPORATION D'IMMEUBLES ARGYLE and its English version ARGYLE REALTY CORP.1358-7266 264, chemin St-Jean.Laprairie.19 08 74 Rue Pointe-Langlois, Sainte-Rose.23 09 74 Brossard.09 09 74 Granby.il 10 74 Saint-Léonard-d'Aston.n 09 74 1010 St.Catherine Street West, suite 410, Montreal.23 08 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971, 106' année, n° U 8183 Nom / Name CORPORATION DES MANUFACTURES CASTOR.and its English version BEAVER MANUFACTURING CORPORATION 1369-8493 LA CORPORATION DE PLACEMENTS RENAUD.et sa version anglaise RENAUD INVESTMENTS CORPORATION 1359-0732 CORPORATION TAXLESS (QUEBEC) LTEE.and its English version TAKLESS CORPORATION (QUEBEC) LTD.1369-4989 RAYMOND COUTURIER INC.1359-1953 CREATIONS SAAD INC.et sa version anglaise SAAD CREATIONS INC.1354-6213 DECORATION CLAUDETTE DESMARAIS INC.et sa version anglaise CLAUDETTE DESMARAIS DECORATION INC.1369-6562 DEMOBEC INC.1369-5622 DISTRIBUTIONS T.N.R.INC.1369-4732 DISTRIBUTION TONIPRO INC.1359-0146 DOMAINE AIR PUR INC.1359-5749 DOMAINE DU LAC MARTIN INC.1358-3182 DOMAINE R.G.N.INC.1359-4916 LA DRAPERIE CANADIENNE INC.1357-4363 ECOLE DE BOXE DROUIN INC.1369-6778 ECOLE DE CONDUITE ST-PASCAL INC.1359-7075 LES ENTREPOTS M.D.G.INC.et sa version anglaise M.D.G.STORAGE INC.1359-2308 LES ENTREPRISES ATFA INC.et sa version anglaise ATFA ENTERPRISES INC.1359-2688 LES ENTREPRISES CITE JEUNE LTEE.1359-4312 LES ENTREPRISES DE DRAINAGE G.H.F.C.INC.1369-8485 ENTREPRISES FRAGISKOS INCORPOREE.1355-2674 Incorporation Siège social / Head Office Date 1440 Towers Street.Suite 100, 30 09 74 Montreal.Saint-Eustache.11 09 74 Montreal North.29 08 74 7, rue Parent, Lauzon.18 09 74 7665.boulevard St-Laurent, Montréal.03 05 74 Saint-Lambert.16 09 74 Montréal.05 09 74 Laval.27 08 74 28, rue St-Denis, Victoriaville.06 09 74 Val-David.07 10 74 Notre-Dame-de-Mont-Carmel.05 08 74 Saint-Georges.02 10 74 1524, rue Aylwin, Montréal.11 09 74 1306, Mont-Royal est, Montréal.17 09 74 1788, delà Canardière, Québec.16 10 74 Vimont, Laval.19 09 74 Saint-Léonard.23 09 74 Montréal.30 09 74 Mont-Saint-Michel.30 09 74 15, rue Prévost, Longueuil.24 07 74 8184 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1971, Vol- 106, No.11 Incorporation Nom / Name Siège social / Head Office ENTREPRISES IMMOBILIERES W.G.INC.770, rue Notre-Dame ouest, Montréal.07 10 74 1369-9541 LES ENTREPRISES JACSAR LTEE.108, rue St-Jean-Baptiste, Oka.18 09 74 1359-1979 LES ENTREPRISES JOVER LTEE.440, rue Boischatel, Sherbrooke.12 08 74 et sa version anglaise JOVER ENTERPRISES LTD.1358-4511 ENTREPRISES L.F.INC.52, Sacré-Coeur, Charlemagne.01 10 74 1369-4054 LES ENTREPRISES LES SEPT LTEE.3, rue St-Georges, Pointe-Gatineau .07 10 74 1359-5764 LES ENTREPRISES LESRIE INC.Les Saules.30 09 74 1359-4262 LES ENTREPRISES LIONEL GUILBAULT INC.194, boulevard St-Joseph, Hull.17 09 74 1369-6927 LES ENTREPRISES ROD MALAY INC.3650, rue Aylmer, Montréal.08 10 74 and its English version ROD MALAY ENTERPRISES INC.1369-9640 LES ENTREPRISES ROGER CHAPUT, GRANBY INC.269, Montcalm, Granby.26 09 74 1359-4056 LES ENTREPRISES TOURISTIQUES TIKOUAPE INC.Saint-Méthode.09 09 74 1359-0344 LES ENTREPRISES W.D.G.S.LTEE.Montréal.28 08 74 1358-7662 EQUIPEMENTS DE BUREAU INTER-CITE INC.970 Lamer Street, Suite 6, Saint- 11 09 74 and its English version Laurent.INTER-CITY OFFICE EQUIPMENT INC.1369-6273 ESTAMPILLAGE LASRY INC.3400, boulevard Métropolitain.06 09 74 et sa version anglaise Montréal.LASRY STAMPING INC.1369-5671 EWING & RECORDS INC.615 Dorchester Boulevard West.25 09 74 1369-8063 Apt.1010.Montreal.LES EXCACATIONS DAIGLE INC.Val-Bélair.27 08 74 1358-8074 .fASTEXINC.73, Pointe-Langlois, Sainte-Rose.30 09 74 1369\u20148550 FER ORNEMENTAL D.P.INC.Laval.27 08 74 1369-4724 .F,LJU^TE EVE INC.Centre d'Achat Duvernay.boulevard 10 10 74 1359-6309 de la Concorde, Laval FLJUo?JfTE LUC R0Y INC.120.rue principale, Granby.04 09 74 FOURNITURE DE LINGE VAUDREUIL INC.304, Route 17, Rigaud.27 08 74 et sa version anglaise VAUDREUIL LINEN SUPPLY INC.1358-7969 FOURRURES CLAUDE BISSON INC.366.rue Mayor.Montréal.10 09 74 et sa version anglaise \" * * CLAUDE BISSON FURS INC.1369-3734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971, 106- année, n° U 8185 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date GARAGE C.-E.TREMBLAY INC.1359-0393 Beauport.GARAGE D.& M.BLAIS INC.1368-7181 GELBEC INC.1359-4791 GESTION CONSEIL DE MONTREAL INC.1359-6499 GESTION PIMA LIMITEE.and its English version PlMA MANAGEMENT LIMITED 1369-6869 GESTIONS W.KAISER LTEE.and its English version W.KAISER HOLDINGS LTD.1369-3932 C.GOLDEN ET ASSOCIES LTEE.and its English version C.GOLDEN AND ASSOCIATES LTD.1369-8725 GROSSISTE EN PLOMBERIE C.B.K.LTEE.and its English version C.B.K.WHOLESALE PLUMBING SUPPLY LTD.1369-9525 GUATAMA INC.1369-9343 LES HABITATIONS A.PASCAL INC.1358-1186 ILLUSTRATIONS GLORIA INC.and its English version GLORIA ILLUSTRATIONS INC.1369-9434 LES IMMEUBLES G.C.GAGNON INC.et sa version anglaise G.C.GAGNON REALTIES INC.1359-0286 LES IMMEUBLES J.M.LEGAULT INC.1369-9319 LES IMMEUBLES MARASHCO LTEE.and its English version MARASHCO REALTIES LTD.1369-1191 LES IMMEUBLES MOCLAR INC.and its English version MOCLAR ESTATES INC.1359-3397 IMMEUBLES REBOK LTEE.and its English version REBOK PROPERTIES LTD.1370-0059 LES IMMEUBLES SEMAR LTEE.and its English version SEMAR REALTY LTD.1369-6026 1575, Chemin Ste-Angélique, Saint-Lazare.L'Assomption.Laval.Montreal.6339 St.Hubert Street, Suite 306, Montreal.630 Sherbrooke Street West,.Suite 311, Montreal.Montréal.233.rue Caumartin.Boisbriand .Notre-Dame-de-Portneuf.369, Metcalfe, Westmount.7200, avenue Jean-Bourdon, Montréal.27, rue Robillard, Sainte-Thérèse.620 McCaffrey Street, Saint-Laurent .09 09 74 20 06 74 14 02 74 11 10 74 07 10 74 19 08 74 30 09 74 07 10 74 04 10 74 25 07 74 04 10 74 09 09 74 04 10 74 25 07 74 5344.avenue Verdun, Verdun.25 09 74 1155 Dorchester Boulevard West, suite 3900, Montreal.Montréal.LES IMMEUBLES T.L.G.INC.1358-6227 10, chemin St-Georges, Jonquière.11 10 74 10 09 74 20 08 74 8186 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2.1974, Vol.106, No.44 Nom / Name Siège social / Head Office LES IMMEUBLES YIP INC.1359-5780 IMPORT-EXPORT C.D.M.LTEE.1359-2209 IMPRIMERIE LE ROY-AUDY INC.1359-3256 LES INDUSTRIES AXE INC.et sa version anglaise AXE INDUSTRIES INC.1369-6265 LES INDUSTRIES CANTEM LTEE.et sa version anglaise CANTEM INDUSTRIES LTD.1369-7446 LES INDUSTRIES DALUMO LTEE.et sa version anglaise DALUMO INDUSTRIES LTD.1369-8220 LES INDUSTRIES H.R.E.LTEE and its English version H.R.E.INDUSTRIES LTD.1359-3132 LES INDUSTRIES ROLBEC INC.and its English version ROLBEC INDUSTRIES INC.1369-7214 INKEL & FRERES INC.1358-6235 INVESTISSEMENTS SYLVANA INC.and its English version SYLVANA INVESTMENTS INC.1369-0706 EDDY JALBERT INC.1359-3959 Incorporation Date 255.41e Rue ouest, Charlesbourg.16 09 74 Cap-Rouge.13 09 74 Québec.25 09 74 Montréal.11 09 74 280 ouest, rue Sauvé, Montréal.23 09 74 800, Place Victoria, suite 612, Montréal.Montreal.27 09 74 24 09 74 LES JARDINS BEAULIEU INC.1359-0815 JOUETS PRINC-YAL INC.1357-5006 LABORATOIRE DE PHOTO COULEUR SOLLEVANTI INC.and its English version SOLLEVANTI PHOTO-COLOR LABORATORY INC.1369-9822 LAFERRIERE & CORDEAU LTEE.1358-7910 LA LIBRAIRIE DOUBLE CROCHET INC.and its English version THE DOUBLE HOOK BOOK SHOP INC.1369-8790 LA LIGUE DE TAXI DE BELOEIL INC.1358-6094 .LOCATION D'AUTOMOBILES F.C.MATANE LTEE.et sa version anglaise P.C.AUTOMOBILE LEASING MATANE LTD.1359-0492 165, Lafayette.Pont-Viau, Laval.20 09 74 32, 9ième Rue sud, Amos.20 08 74 1117 St.Catherine Street West, 19 07 74 Saint-Romuald.26 09 74 4, Parc Samuel Holland, chambre 403, 11 09 74 Québec.Princeville.27 06 74 Montréal.09 10 74 9062, Périnault, Saint-Léonard.27 08 74 Montréal.oi 10 74 481, Choquette, Beloeil.16 08 74 Petite Matane.09 09 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.S novembre MA, 106' année, no AA 8187 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LOCATION DE GRUES MONTREAL LTEE.and its English version MONTREAL CRANE RENTALS LTD.1369-8766 Montréal.LOUGEC INC.1359-1847 MAÇONNERIE GALLI LTEE.and its English version GALLI MASONRY LTD.1369-8311 MAGAMA INC.1359-4304 MAISONS USINEES LANDRY INC.1358-5583 MARCHE FERNAND GRAVELINE INC.1369-6729 MARCHE YVON DEZAINDE INC.1369-8576 MARQUIS LAFLEUR INC.1359-1508 R.MASON INC.1357-5436 MENARD, MARSAN & ASSOCIES INC.1358-6243 BRIAN MERRET & JENNIFER HARPER INC.1369-5580 LES METAUX WERNER INC.and its English version WERNER METALS INC.1369-4872 MINI AUTO SPORT ST-LEONARD INC.1357-9776 MAURICE MONETTE LTEE.1369-9459 MOTEL LA CAMPAGNE INC.1359-2118 NAVIGATION G.TREMBLAY LTEE.1359-5228 OUTILS ET TEINTURES CARILLON INC.and its English version CARILLON TOOL & DYE INC.1369-6851 ROGER D.PAQUETTE ET ASSOCIES LTEE.1369-7974 PAYSAGISTES AMALFI INC.et sa version anglaise AMALFI LANDSCAPING INC.1369-5440 LES PAYSAGISTES IZZO ET FRERES LTEE.and its English version IZZO BROTHERS LANDSCAPE CONTRACTORS LTD.1368-5003 8245, rue Notre-Dame est, Montréal.4319, Marlin Crescent, Pierrefonds.170, 4ième Avenue, Saint-Timothée.2255, boulevard Talbot, (Place des Soeurs Sud), Chicoutimi.Saint-Hyacinthe.3515, Mountain View, Saint-Hubert.540, rue Lièvre, Buckingham.Richmond.Rimouski.1245 St.Marc Street, Apt.22, Montreal Montréal.Saint-Léonard-d'Aston.28, rue Ste-Anne, Pointe-aux-Trembles Sainte-Marthe.Saint-Bernard-de-l'Ile-aux-Coudres.13238 Racine Street, Pierrefonds.759, Carré Victoria, Montréal.10976, rue Ethier, Montréal-Nord____ 01 10 74 17 09 74 27 09 74 30 09 74 15 08 74 16 09 74 30 09 74 16 09 74 27 06 74 20 08 74 05 09 74 28 08 74 22 07 74 04 10 74 18 09 74 04 10 74 17 09 74 25 09 74 04 09 74 Montréal.03 06 74 8188 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date PEINTURE METROPOLITAINE INC.and its English version METROPOLITAN PAINTING INC.1369-9277 PEINTURE R.ET R.PROSSER INC.and its English version R.AND R.PROSSER PAINTING INC.1369-5614 Montréal.03 10 74 30 Henriette Street, Chambly.05 09 74 JACQUES PELADEAU INC.1369-7388 PIERRE A MUR FUTURISTE DE VAL BELAIR INC.1359-1813 123, de l'Etoile, Laval-des-Rapides, Laval.PLACE BERELI INC.1359-4718 PLACEMENTS A.ST-GERMAIN INC.1369-8246 LES PLACEMENTS LE BEC-FIN INC.1359-6481 1531.Eliot, Val-Belair.Saint-Albert-de-Warwick.2028, Francis, Saint-Hubert.Québec.PLACEMENTS BETSHEL LTEE.and its English version BETSHEL INVESTMENTS LTD.1369-8121 PLACEMENTS DISTINCTION INC.1357-5907 LES PLACEMENTS GEMEAUX INC.and its English version GEMINI HOLDINGS INC.1359-4502 1.Place Ville-Marie, Suite 1540, Montréal.Montréal.Montréal.LES PLACEMENTS GROU LTEE.360, rue St-Jacques, suite 1606, et sa version anglaise Montréal.GROU HOLDING LTD.1359^716 PLACEMENTS HARLEE LTEE.1.piace Ville-Marie, Suite 1540, and its English version Montréal.HARLEE INVESTMENTS LTD.1369-8360 P369C3E»0ENTS JD' LIMITEE3050.Montée St-Hubert.Saint-Hubert PLACEMENTS JP.VIAU INC.152.rue Principale.Châteauguay.et sa version anglaise J.P.VIAU INVESTMENTS INC.1368-6464 LEfs gâSSS?JACE INC.6255 «¦* B\u2014rd.Montreal.JACE INVESTMENTS INC.1369-7248 LES PLACEMENTS K.B.d.INC cKK j\u201e i v i ¦ o ¦ \u2022 .1358-7399 .5b5, de la Falaise, Saint-David-de- L'Auberivière.PLACEMENTS MOLIDA LTEE____ and its English version MOLIDA INVESTMENTS LTD.1369-8113 1, Place Ville-Marie, Suite 1540, Montréal.LES PLACEMENTS VALJOU INC.\u201e\u2022\u201e 1359-2605 .A\")0 23 09 74 17 09 74 01 10 74 27 09 74 11 10 74 26 09 74 04 07 74 27 09 74 11 09 74 27 09 74 13 08 74 11 09 74 20 09 74 23 08 74 26 09 74 23 09 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8189 Nom / Name LES PLANTATIONS BAUME DE WEEDON INC.et sa version anglaise WEEDON BALSAM PLANTATIONS INC.1357-7655 PRODIMPEX INC.1357-4025 LES PRODUCTIONS TEVEQUOISES LIMITEE.1358-7613 LES PRODUITS D'ACIER ROGER INC.et sa version anglaise ROGER'S STEEL PRODUCTS INC.1359-2159 LES PRODUITS CHIMIQUES R.L.INC.1369-8907 PRODUITS ELECTRONIQUES VANDOR LTEE.et sa version anglaise VANDOR ELECTRONIC PRODUCTS LTD.1369-5762 PROMACTION INC.1369-9764 PROMOTIONS ADMIX INC.1369-3429 MARCEL PROULX ET ASSOCIES (1974) INC.1359-0468 QUINCAILLERIE PAUL LAROUCHE LTEE.1358-3570 QUINCAILLERIE ST-LAURENT LTEE.and its English version ST.LAWRENCE HARDWARE LTD.1369-4948 R.RAVARY & ASSOCIES INC.1359-1193 REFRIGERATION D.M.INC.et sa version anglaise D.M.REFRIGERATION INC.1368-9823 RENOS AG INC.1357-3720 RESTAURANT LE BOUFFE-EN-BROCHE INC.1369-8774 RESTAURANT CHEZ GISELE FORGET LIMITEE.1358-3406 RESTAURANT JARDIN DE CAPRI INC.1359-3082 RESTAURANTS MOMENTS LIBRES INC.and its English version LEISURE TIME RESTAURANTS INC.1369-7156 RESTAURANT SAI WOO INC.and its English version SAI WOO RESTAURANT INC.1369-7826 Siège social / Head Office Incorporation Date Route rurale numéro 2.rue Downey, Lennoxville.10 07 74 Montréal.06 09 74 202, rue Aberdeen, Québec.28 08 74 1973, rue Roger.Saint-Paul l'Ermite.18 09 74 8671, lOième Avenue, Saint-Michel.02 10 74 8486, rue Albanel, Saint-Léonard.06 09 74 4, Carré Westmount, Westmount.08 10 74 1010 St.Catherine Street West, 14 08 74 Apt.607, Montreal.620 - 4e Avenue, Lachine.09 09 74 Saint-Coeur-de-Marie.07 08 74 4127 St.Lawrence Boulevard, 29 08 74 Montreal.902, rue St-Maurice, Trois-Rivières.12 09 74 10775, rue Lamoureux, Montréal- 12 07 74 Nord.Chicoutimi.13 09 74 Saint-Sauveur.01 10 74 Saint-Jean.04 09 74 Saint-Charles-Borromée.08 10 74 Montréal.19 09 74 Saint-Constant.24 09 74 8190 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Nom / Nome Siège social / Head Office Incorporation Date REVETEMENTS DE CERAMIQUE ET DE TERRAZZO B.& P.INC.et sa version anglaise B.ce P.TILE AND TERRA7.Z0 INC.1369-8139 RIOUX ET PAQUET INC.1359-5889 LOUIS ROEDERER & ASSOCIES INC.1369-7263 J.P.ROY ET ASSOCIES INC.and its English version J.P.ROY AND ASSOCIATES INC.1369-4294 j.A.ST-GERMAIN (1974) INC.1369-8238 SALON DE BEAUTE DE LA FEMME DE L'AN 2,000 INC.and its English version WOMEN OF THE YEAR 2.000 BEAUTY SALON INC.1369-9145 SAUNAS LAROSE INC.et sa version anglaise LAROSE SAUNAS INC.1369-5531 JEAN-PAUL SAUVE INC.1369-6331 LES SECHOIRS A BOIS RUE BERNARD LTEE.1359-4429 SECURITE SELECT INC.et sa version anglaise SELECT SECURITY INC.1367-6887 LES SERVICES MARITIMES FRIEMAR LTEE.and its English version FRIEMAR MARINE SERVICE LTD.1369-6240 SERVICE DE PROJETS D'ORGANISATION O.D.S.LTEE.and its English version O.D.S.ORGANIZATION DESIGN SERVICES LTD.1369-4823 SERVICE DE RESSORTS ROBERT INC.et sa version anglaise ROBERT SPRING SERVICE INC.1358-9098 LA SOCIETE D'ADMINISTRATION D.L.INC.1369-9301 SOCIETE D'ART ET DECORATION YVES PREVOST INC.1369-6547 6305.rue Jean-Talon est, app.6.Saint-Léonard.225, avenue St-Michel, Beauport.1400, avenue des Pins ouest, chambre 1104, Montréal.Morin Heights.2737, rue Mackay, Saint-Hubert.04 10 74 11 02 74 20 09 74 23 08 74 27 09 74 4221-A Samson Boulevard, Chomedey.02 10 74 Laval.6851, St-André, Montréal.04 09 74 Main Road, Hudson.11 09 74 Beauceville.30 09 74 360, rue Jean-Talon est, Montréal.05 04 74 410 St.Nicholas Street, Coristine 11 09 74 Building, Montreal.5165 Sherbrooke Street West, suite 419, Montreal.28 08 74 SOCIETE DE GESTION F.L.M.INC.1358-3448 SOCIETE IMMOBILIERE MCDERPOZ INC 1359-5913 SOCIETE IMMOBILIERE QUEBEC METROPOLITAIN I\\C 1359-3876 SOCIETE DE RECHERCHE EXAR LIMITEE.et sa version anglaise EXAR RESEARCH CORPORATION LIMITED 1369-8873 Route Rurale numéro 5, Lac-Mégantic 29 08 74 3, Place Laval, suite 500, Laval.04 10 74 Bois-des-Filion.15 09 74 640, 128e Rue, Shawinigan-Sud.15 08 74 4300, 1ère Avenue, Laval Ouest.24 01 74 170, rue Grande-Allée ouest, Québec 26 09 74 612, rue St-Jacques, Montréal.01 10 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1974, 106' année, no 44 8191 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date SPANCOLINC.1358-8785 STATION DE SKI L'ELAN.1359-7356 SUPERMARCHE PISTILLI INC.and its English version PISTILLI SUPERMARKET INC.1369-6703 LES SYSTEMES DE CONTAINERS (QUEBEC) (1974) LIMITEE and its Englisn version CONTAINER SYSTEMS (QUEBEC) (1974) LIMITED 1358-7050 LES TAPIS TANGUAY INC.1358-7563 TARDIF, GINGRAS ET ASSOCIES INC.et sa version anglaise TARDIF.GINGRAS AND ASSOCIATES INC.1369-7925 J.MAURICE TARDIF INC.1358-2846 TELEMISSIB LIMITEE.1359-0151 TELEVISION ET STEREO EXPRESS INC.1359-5137 LES TEXTILES TANIA INC.et sa version anglaise TANIA TEXTILES INC.1358-7779 TOUCHETTE ET LEGAULT INC.1367-2522 LA TOURNEE DES GRANDS SPECTACLES DE SOREL 1358-6656 TRAVERSIER LE PASSEUR INC.1369-2330 TRICOTS ALBERTO D'ITALIE LTEE.and its English version ALBERTO OF ITALY KNITWEAR LTD.1369-5226 VALMORNO INC.1359-0047 LES VENTES TRIPLE E LTEE and its English version TRIPLE E SALES LTD.1369-6257 LES VENTES YANOW LTEE .and its English version YANOW SALES LTD.1369-9046 VETEMENTS L.G.G.LIMITEE.and its English version L.G.G.CLOTHING LIMITED 1369-5135 680, rue Lenoir, Sainte-Foy.East-Angus.Montreal.30 08 74 17 10 74 16 09 74 585.rue Ste-Rose, Laprairie.22 08 74 515, Bonne-Entente, Drummondville.1375, rue Notre-Dame.Lachine.Saint-Méthode.Bedford.Sept-Iles.24, rue St-Joseph ouest, Québec.25, rue Milton, Saint-Pierre.Sorel.Carillon.1435 St.Alexander Street.Room 200, Montreal.Québec.6505, Côte St-Luc.app.216.Côte Saint-Luc.Montreal 26 08 74 25 09 74 11 09 74 09 09 74 03 10 74 28 08 74 19 03 74 20 08 74 30 08 74 30 08 74 05 09 74 11 09 74 02 10 74 2195.LaBelle.Longueuil.30 08 74 58868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 Pierre Desjardins.Director of the Companies Service. 8192 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Lettres patentes (3' partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives, notice that, pursuant to l'art 111 de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act.he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Xame Siège social / Head Office Incorporation Date L'ASSOCIATION DES AIDES AUX MALADES L'ARC-EN-CIEL INC.1358-7340 L'ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA COTE NORD INC.1359-5558 ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN GEOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 1368-2638 ASSOCIATION DES INSTRUCTEURS DE TENNIS DU QUEBEC INC.1369-6034 ASSOCIATION DES LOCATAIRES DES APPARTEMENTS MARIE DE L'INCARNATION INC.1358-4610 L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC 8T-SEB ASTI EN, COMTE BERTHIER 1369-1433 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU MONT BON PLAISIR INC.1369-6497 ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSEILLERS DE VENTES INC.1369-1268 LE CLUB DE L'AGE D'OR DE SAINT-THEODORE DE CHERTSEY 1359-0013 LE CLUB DES AINES NOMADES DE L'ILE DE MONTREAL (C.A.N.I.M.) et sa version anglaise SENIORS NOMAD CLUB OF THE ISLAND OF MONTREAL (C.A.N.I.M.) 1358-7241 LE CLUB DES FRANCS GOURMETS DE LA TUQUE INC 1358-1392 CLUB DES LOISIRS DU CANTON PERCE.1359-1821 CLUB DE PLEIN AIR DE MORIN HEIGHTS.and its English version MORIN HEIGHTS OUTING CLUB 1369-5606 COMITE QUEBECOIS DES SENTIERS DE RANDONNEE INC.746294 COMMANDAIR INC.1359-2811 ECOLE DE SKI NAUTIQUE LES INTREPIDES .1368-7266 Hôpital du Saint-Sacrement, 1050, chemin Ste-Foy, Québec.23 08 74 Baie-Comeau.07 10 74 Montréal .02 10 74 Montréal 20, rue Marie-de-lTncarnation, Québec.Montréal 10 09 74 26 09 74 13 09 74 Mont-Bon-Plaisir, Stukely-Sud.04 10 74 2950, rue Masson.Montréal .13 09 74 370, rue Dupuis, Chertsey.02 10 74 7695, rue Papineau.Montréal.23 08 74 16, rue Iberville, La Tuque.29 07 74 Cap-d'Espoir.17 09 74 Morin Heights.27 08 74 Montréal.01 02 74 Aéroport de Sherbrooke, East Angus .24 09 74 3120.rue Monsabré, Montréal.20 00 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 197i, 106' année, no U Nom/ Name Siège social / Head Office Incorporation Date FONDATION LES LUTINS DU CHATEAU.1369-3692 LA FONDATION MGR.JOSEPH CHEVALIER.1367-6681 LIGUE DES PROPRIETAIRES DE GRANTHAM-OUEST.1356-8118 LA LIGUE DES TAXIS DE ST-JEROME INC.1358-8777 LA LIGUE DE TAXIS DE VAL D'OR INC.1358-2986 L'ORDRE LOYAL DES MOOSE (LOGE 858 SOREL) INC.et sa version anglaise LOYAL ORDER OF MOOSE (SOREL LODGE 858) INC.1369-1870 SERVICES AUX PERSONNES AGEES \u2014PROJET CHANGEMENT et sa version anglaise PROJECT CHANGE \u2014 SERVICES FOR THE ELDERLY 1366-1923 18393 ouest, boulevard Gouin, Pierrefonds.85, boulevard Archambault, Pointe-Gatineau.16 08 74 05 07 74 2090, Auguste, Drummondville.23 06 74 265, Ste-Paule, Saint-Jérôme.30 08 74 215, 3e Avenue, Val-d'Or.10 09 74 263, rue George, Sorel.17 09 74 3553, Saint-Urbain, Suite 300, Montréal.24 09 74 58868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the il a accordé des lettres patentes supplémentaires a: Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes A.N.I.(CENTRAL) LIMITED.20 05 47 3701-47 LES ALIMENTS LEAHY INC.et sa version anglaise: LEAHY FOODS INC.1367-3728 ARBOUR ET VIDAL INC.11366-62 05 03 74 04 04 62 B.S.8.INC.10 11 71 716038 BAIE 8T-PAUL AUTOMOBILE INC.744-70 BRASSERIE ENTRE POTS INC.01 08 74 1368-2432 29 04 71 1) Ancien nom / Former name: IMBREX QUEBEC LIMITEE IMBREX QUEBEC LIMITED.2) Modifiant le capital / Altering the capital.3) Etendant les pouvoirs / Extending the powers.30 09 74 Ancien nom / Former name: LES PRODUITS ALIMENTAIRES LEAHY INC.LEAHY'S FOOD PRODUCTS INC.04 10 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant quelques dispositions des lettres patentes / Amending some provisions of the letters patent.17 07 74 Modifiant le capital / Altering the capital.17 02 70 03 09 74 Modifiant le capital / Altering the capital.13 08 74 Ancien nom / Former name: BRASSERIE MILLE NEUF CENT TRENTE INC. 8194 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.IPG.No.44 Incorporation Nom / Name Date BRAULT.GUY.O'BRIEN INC.31 12 64 21-65 CALAIS DEVELOPMENT INC.19 05 72 722774 CENTRE COMMERCIAL DEUX MILLE INC.22 09 72 729028 CENTRE COMMERCIAL LA TUQUE LTEE .02 10 72 725466 CLUB DE TENNIS MONTCALM INC.12 07 71 3707-71 LE CLUB DE SQUASH VILLE-MARIE INC.22 10 73 et sa version anglaise: VILLE-MARIE SQUASH CLUB INC.734653 COLDOR CHINCHILLA RANCH INC.24 09 69 4508-69 LES COMPRESSEURS GELINAS INC.28 11 55 et sa version anglaise: GELINAS COMPRESSORS INC.13090-55 CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS DE LA 10 12 65 RIVE-SUD.5378-65 CONSTRUCTION BELAND INC.02 09 70 3687-70 CONSTRUCTION OTTAMONT INC.20 03 68 et sa version anglaise: OTTAMONT CONSTRUCTION INC.1268-68 CONTINENTAL FINANCE CORPORATION .21 01 64 CORPORATION FINANCIERE CONTINENTAL.291-64 MARCEL DEAUDELIN INC.31 12 70 5698-70 DIREQUAIR INC.27 10 68 12730-58 DUPRAS-FALET INC.24 08 73 737955 LES ENTREPRISES ROCH SAVAGE LTEE 22 05 73 732338 FERMANAGH LIMITEE.25 08 71 and its English version: FERMANAGH LIMITED 714467 SIDNEY FRIEDMAN INC.13 04 67 1380-67 GLENORA SECURITIES.INC.15 03 24 494-24 HONCO INC.26 04 74 1356-1600 L.P.S./ S.L.P.Date Modifications Changes 18 09 74 1) Ancien nom [Former name: BRAULT.ÔUY.CHAPUT INC.2) Modifiant le capital / AUerino the capital.16 08 74 Modifiant le capital / Altering the capital.28 08 74 Ancien nom / Former name: HYPERMARCHE LAVAL INC.27 08 74 Ancien nom / Former name: CENTRE COMMERCIAL LA PROMENADE (JOLIETTE) LTEE.03 10 74 1) Modifiant les pouvoirs/ Modifying the power b.2) Modifiant les dispositions des lettres patentes / Modifying the provisions of the letters patent.08 10 74 Ancien nom / Former name: LE CLUB DE SQUASH DE MONTREAL INC.MONTREAL SQUASH CLUB INC.09 09 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.17 09 74 Ancien nom / Former name: GELINAS COMPRESSORS AND PAINT SPRAYERS.INC.25 09 74 Ancien nom / Former name: LE SERVICE DES LOISIRS DE LA RIVE-SUD METROPOLITAINE.28 06 74 Ancien nom / Former name: LES CONSTRUCTIONS FAGI INC.17 06 74 Ancien nom / Former name: OTTAMONT ASPHALTE INC.OTTAMONT ASPHALT INC.27 09 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital.2) Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.12 08 74 Modifiant le capital Alterini th.capital.24 09 74 Ancien nom / Former name: DOLBEAU AIR SERVICE INC.27 09 74 Ancien nom / Former name: DUFALCO INC.25 06 74 Modifiant le capita] / Altering the capital.03 06 74 Ancien nom / Former name: FO-MEC INDUSTRIES LTD.05 08 74 Modifiant le capital / Altering the capital.01 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital.09 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8195 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes IMMEUBLES K.C.K.LTEE.17 04 62 et sa version anglaise: K.C.K.REALTIES LTD.11641-62 LES INDUSTRIES B.& R.LTEE.28 06 73 B.& R.INDUSTRIES LTD.732955 LES INDUSTRIES DORION INC.20 06 66 2607-66 INTER-ROUILLE VAUDREUIL-SOULANGES 08 11 72 LTEE VAUDREUIL-SOULANGES INTER-PUTT LTD.729313 LEMCO.DISTRIBUTEURS D'ELECTRONI- 26 11 59 QUE EN GROS LTEE 16447-59 MAISONS-MOBILES CHIBOUGAMAU INC.06 04 71 1064-71 MATERIO DESLAURIERS INC.18 11 49 8583-1949 MATERIO GOULET (1974) INC.16 04 43 2945-43 PAPIER CASCADES (CABANO) INC.21 06 74 1368-7348 PHILDAR LTD.28 04 72 722235 PILOTE & FRERES CONSTRUCTION INC.26 10 71 715712 J.A.PROULX INC.29 11 73 738876 17 03 61 LE SERVICE DE DISTRIBUTION RICHELIEU INC.724756 LES SERVICES FINANCIERS CHEMICAL LIMITEE and its English version: CHEMICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 11385-61 STURO METAL INC.23 03 73 METAL STURO INC.731311 MAURICE THIBAULT LTD.15 12 55 13367-55 VIN GELOSO INC.30 09 65 1114-4466 08 10 74 Ancien nom / Former name: DELTA REALTIES LTD.IMMEUBLES DELTA LTEE.16 08 74 Modifiant le capital / Altering the capital.24 09 74 Etendant les pouvoirs / Extending the powers.02 10 74 Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.05 09 74 Ancien nom / Former name: PRODUITS ELECTRONIQUES EN GROS DES LAURENTIDES LTEE 30 09 74 Etendant les pouvoirs / Extending the powers.01 10 74 Ancien nom / Former name: MATERIO GOULET INC.01 10 74 Ancien nom / Former name: ALPHONSE GOULET LTEE.08 10 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Changeant le nombre des administrateurs / Changing the number of directors.14 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital.07 06 74 Modifiant le capital / Altering the capital.19 09 74 Ancien nom / Former name: EMBALLAGE PROULX INC.PROULX PACKAGING INC.25 08 72 25 09 74 Modifiant le capital / Altering the capital.09 07 74 1) Ancien nom / Former name: DORVAL THEATRE CO.LTD.2) Modifiant le capital / Altering the capital.3) Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers.4) Modifiant les privilèges et restrictions.Modifying the privileges and restrictions.5) Modifiant quelques dispositions aux lettres patentes / Modifying some provisions at the letters patent.16 09 74 Modifiant le capital / Altering the capital.04 10 74 Modifiant le capital / Altering the capital.19 09 74 Modifiant le capital / Altering the capital.58868-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. S I'M.QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November S, 1974.Vol.10G.No.44 Avis de correction (Lettres patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies _ et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Nom / X'ame Siège social Incorporation Head Office Date Modifications Corrections CONSTRUCTIONS ARMAND JEANSON INC.1358-6375 3351.rue Bélair, 19 08 74 Corrigeant le nom / Correcting the name: Sherbrooke CONSTRUCTION ARMAND JEAN- SON INC.par / by CONSTRUCTIONS ARMAND JEANSON INC.I.e directeur du sereice des compagnies, l'unit Desjardiks.5ss6v-.Pierre Desjardins.Director of the Companies Service.Demandes d'abandon de charte Applications for Surrender of Charter DE MARTIN-MARONA OF CANADA, LTD.Avis est |>ar les présentes donné que la compagnie « DE MARTIN-MARONA OF CANADA, LTD.», constituée en corporation en vertu de la I/ji des compagnies et ayant son siège social dans a ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 21 octobre 1974.Les procureurs de la compagnie, Robinson, Sheppard, Bohenstein, 58875-0 Shapiro & Flam.LES PLACEMENTS ROMA INC.Prenez avis que la compagnie « LES PLACEMENTS ROMA INC.», ayant son siège social à Lachine.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Ce 3 octobre 1974.l.e notaire, 255.14e Avenue.Leopold Gaston.Lachine.Que.58880-o TAVERNE 3700 INC.Avis est donné que la compagnie « TAVERNE 3700 INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 30 septembre 1974.Le secrétaire.Et cène PoUPART.5888l-o DE MARTIN-MARONA OF CANADA, LTD.Notice is hereby given that \"DE MARTIN-MARONA OF CANADA.LTD.\".a corporation incorporated under the Companies Act.and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 21st day of December, 1974.Robinson, Sheppabd, Bobenstbin, Shapiro & Flam.58875-0 Attorneys for the company.LES PLACEMENTS ROMA INC.Notice is hereby given that \"LES PLACEMENTS ROMA INC.\".having its head office at Lachine.will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for permission to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.October 3.1974.255 - 14th Avenue, Lachine, Que.Leopold Gaston, Notart/.5SSN0 TAVERNE 3700 INC.Notice is hereby given that the company \"TAVERN 3700 INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to surrender its charter.Montreal, September 30th.1974.Eugène Poupajit, Secretary.5S881-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8197 BROOKMERE DEVELOPMENT CORPORATION Avis est par les présentes donné que la compagnie «BROOKMERE DEVELOPMENT CORPORATION », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 15e jour d'octobre 1974.Les procureurs de la requérante, (\"fiait, Salomon, Gelbbr, Reis, Bronsteix & Litvack.1, Place Ville-Marie, Montréal.58874 ERDICk INC.Avis est donné par les présentes que « ERDICK INC.», constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la cité de St-Laurent, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 17e jour de septembre 1974.Les procureurs de la compagnie, Noël, Boxer, & Feldman.10 St-Jacques, Montréal.58876-0 BROOKMERE DEVELOPMENT CORPORATION Notice is hereby given that \"BROOKMERE DEVELOPMENT CORPORATION\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, on this 15th day of October, 1974.Chait, Salomon, Gelber, Reis, BrONSTEIN & LlTVACK, Attorneys for the company.1 Place Ville-Marie.Montreal.58874-0 ERDICK INC.Notice is hereby given that \"ERDICK INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of St.Laurent, district of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 17th day of September, 1974.Noel, Boxer & Feldman, Attorneys for the company.10 St.Jacques, Montreal.58876-0 FONDATION AGE D'OR DU QUEBEC INC.Avis est par la présente donné que la « FONDATION AGE DOR DU QUEBEC INC.», demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 2 octobre 1974.Le notaire.58877-0 Me Jacques Morand.LUMIC LIMITEE Avis est par les présentes donné que la compagnie « LUMIC LIMITEE », constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et sa principale place d'affaires en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 15e jour d'octobre 1974.Les procureurs de la compagnie, Chait, Salomon, Gelbeb, Reis, Bronstein & Litvack.1, Place Ville-Marie, Montréal, Que.58879 FONDATION AGE D'OR DU QUEBEC INC.Notice is hereby given that \"FONDATION AGE D'OR DU QUEBEC INC.\", will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter.Montreal, October 2nd, 1974.Me Jacques Morand, 58877-0 Notary.LUMIC LIMITEE Notice is hereby given that \"LUMIC LIMITEE\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, on this 15th day of October, 1974.Chait, Salomon, Gelber, Reis, Bronstein & Litvack, Attorneys for the company.1 Place Ville-Marie, Montreal, Que.58879-o S198 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 LANDHOLD PROPERTIES LTD.LES IMMEUBLES L.VNDHOLD LTEE Avis est donné que « LANDHOLD PROPERTIES LTD.\u2014 LES IMMEUBLES LANDHOLD LTEE», compagnie constituée en corporation selon la Loi des compagnies, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, Québec, ce 22e jour d'octobre, 1974.Les procureurs de la compagnie, Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, gonthier & tètrault.630, boulevard Dorchester Ouest.Montréal, H3B 1V7 58878-o LANHOLD PROPERTIES LTD.LES IMMEUBLES LANDHOLD LTEE Notice is hereby given that \"LANDHOLD PROPERTIES LTD.\u2014 LES IMMEUBLES LANDHOLD LTEE\".incorporated under the Companies Act, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, Québec, this 22nd day of October, 1974.Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, Gonthier & tétrault, Attorneys for the company.630 Dorchester Boulevard West.Montreal, H3B 1V7 58878-0 LA CIK DE CONTROLE SWIFT LTEE SWIFT CONTROLS CO.LTD.Avis est donné que « LA CLE DE CONTROLES SWIFT LTEE \u2014 SWIFT CONTROLS CO.LTD.».une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 21ième jour d'octobre 1974.Les procureurs de la compagnie, 1440, Ste-Catherine, Ligiitstonb & Riback.Montréal, Que.58890-o LA CIE DE CONTROLE SWIFT LTEE SWIFT CONTROLS CO.LTD.Notice is hereby given that \"LA CIE DE CONTROLES SWIFT LTEE \u2014 SWIFT CONTROLS CO.LTD.\", a corporation constituted under the Companies Act.and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 21st October, 1974.Lightstone & Riback, 1440 Ste-Catherine, Attorneys for the company.Montreal, Que.58890-o CLECO ELECTRIC COMPANY (1969) LTD.Avis est donné que la compagnie « CLECO ELECTRIC COMPANY (1969) LTD.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 21 ième jour d'octobre 1974.Les procureurs de la compagnie, Ligiitstonb & Riback.1440, Ste-Catherine, suite 621 Montréal, Que.58901-o CLECO ELECTRIC COMPANY (1969) LTD.Notice is herebv given that \"CLECO ELECTRIC COMPANY (1969) LTD.\".a corporation constituted under the Companies Act.and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 21st October, 1974.Lightstone & Riback, Attorneys for the company.1440 Ste-Catherine, suite 621 Montreal, Que.58901-o MONTREAL BLUE PRINT INCORPORATED Avis est donné que la compagnie « MONTREAL BLUE PRINT INCORPORATED », constituée par lettres patentes du Quebec en date du 28 mars 1947.s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Le président.58903-O Jacques Brais.MONTREAL BLUE PRINT INCORPORATED Notice is hereby given that the company \"MONTREAL BLUE PRINT INCORPORATED\", constituted by letters patent dated March 28,1947, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jacques Brais, 58903-o President. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 197A, J061 année, n° U 8199 TRANSPORT BERNARD LTEE Prenez avis que la compagnie portant le nom \u2022 demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte.Québec, le 15 octobre 1974.Les procureurs de la compagnie.Gagné, Trotier, Letarte, 2, avenue Chauveau, LaRue & Royer.Québec.58882-0 MARIO R.CABRIEL INC.Avis est par les présentes donné que « MARIO R.GABRIEL INC.» une corporation constituée sous la Loi des compagnies et ayant son siège social à Ste-Adèle, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte selon les dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Ste-Adèle, ce 11 octobre 1974.La secrétaire, 58902-o Victoria B.Gabriel.TRANSPORT BERNARD LTEE Notice is hereby given that the company \"TRANSPORT BERNARD LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Québec, October 15th, 1974.Gagné, Trotier, Letarte, I.aKi ; & Royer, 2 Chauveau Avenue, Attorneys for the company.Québec.58882-0 MARIO R.GABRIEL INC.Notice is hereby given that \"MARIO R.GABRIEL INC.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in Ste.Adèle, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Ste.Adèle, October 11, 1974.Victoria B.Gabriel, 58902-o Secretary.Renseignements sin* les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A.C.M.INC.76182 A & W ENTERPRISES INC.98108 JEAN ADDY CONSTRUCTION LTEE.75443 L'AGENCE DE RECLAMATIONS DE SHERBROOKE INC.82826 AGENCE DE VOYAGES DE HULL INC.59516 AGFA INC.79367 LES AJUSTEMENTS D'ASSURANCES B.E.INC.77034 Montreal.1967 et/and 1973 Val-d'Or.1967.1969, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1966 incl.1968, 1970 à/to 1373 incl.Sherbrooke.1966 à/to 1973 incl.Hull.1966, 1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1971, 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl. 8200 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ALL-CON PRECAST PRODUCTS LTD.71952 ALMUR LTD .76040 ALOUETTE MEAT INC.97475 ALPHA EQUIPMENT MFG.INC.79157 AMERICAN GENERAL SUPPLY OF CANADA (1969) LIMITED 82704 AMEUBLEMENT ST-VICTOR INCORPORE.35831 AMIS DU THEATRE DU SAGUENAY INC.73551 AMUSEMENT ETOILE INC.80733 ANDOVER PRESS LTD.77713 ANDREWS-BOYD LTD.81714 ANDROS INVESTMENTS LIMITED .79368 LES AS DE VICTORIAVILLE INC.81989 ASBESTOS-EASTERN HOLDINGS INC.78011 ASHDON PLASTICS QUEBEC INC.75448 ASSOCIATED MERCHANDISES LTD.77292 ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS INDEPENDANTS DE FILMS D'EXPRESSIONS FRANÇAISE (A.C.D.I.F.) 77715 L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE THEATRE INC____ 81128 L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DE LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL 76753 ASSOCIATION DES EMPLOYES NON-SYNDIQUES DE LA CITE D'OUTREMONT 82833 L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DU BAS ST-LAURENT INC.78802 ASSOCIATION DES GARÇONS DE TABLE DE LA MAURICIE INC.47635 St-Jérôme.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal.Kénogami.Hauterive.Montreal.Montreal.Montreal.Victoriaville.Danville.Montreal Montreal____ Montréal.Montréal.Montréal.1963 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1956.1958 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1967, 1972, 1973 1964 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1964, 1965, 1971 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1964, 1966, 1967, 1969, 1973 1971 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1964 et/and 1973 1965 à/to 1973 incl.1964, 1968 à/to 1973 incl.Outremont.1966 à/to 1973 incl.Ste-Félicité.Trois-Rivières.1964, 1965.1973 1960 à/to 1973 incl.ASSOCIATION IBERO-CANADA 81990 Montréal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, i novembre 1974, 106' année, n° 44 8201 Nom de la compagnie Name of the company L'ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA PLAZA FUSEY INC.78305 ASSOCIATION OF OSTEOPATHIC AND PHYSICIANS AND SURGEONS (QUEBEC) 77393 L'ASSQCIATION DES PARENTS DES ETUDIANTS DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL LIONEL GROULX INC.109382 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU QUARTIER NUMERO UN DE LA VILLE DE GATINEAU INC.79160 ASSOCIATION PROVINCIALE DES INFIRMIERS DU QUEBEC 80887 L'ASSOCIATION RECREATIVE ST-REMI INC.75567 L'ATELIER DE BALLET CLASSIQUE INC.79163 ATELIER DE REMBOURRAGE GIRARD LTEE.81865 ATOMIC FILMS PRODUCTIONS INC.74970 AU CHALET DE LA MONTAGNE INC.75768 AU PETIT CAPORAL INC.81722 AUBERGE ST-PLACIDE LTEE.75569 AUDIO SCIENCE INC.73738 AUTO J.L.LORRAIN INC.73508 AUTO-BUFFET DECCA INC.77395 AVEL ISLAND DEVELOPMENT INC.77006 B & J SPORTSWEAR CO.LTD.82662 BM DYEING INC.79269 B.& M.PACKAGING LTD.81618 B.& M.TILES AND TERRAZZO INC.76658 BARCLAY OVERSEAS SALES CORP.78810 BARI IMPORTING COMPANY INC.78661 BEAUCEVILLE LUMBER CO.LTD.79982 St-Georges.1965 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Cap-de-la-Madeleine____ 1964 à/to 1967 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Blainville.1969 à/to 1973 incl.Gatineau.1964, 1966 à/to 1973 incl.Roberval.1972 et/and 1973 St-Rémi.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964, 1966, 1967, 1971 à/to 1973 incl.Bagotville.1965 à/to 1970 incl., 1972 et/and 1973 Ville Laval.1964 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965, 1967, 1971, 1973 Montreal.1965, 1966, 1968, 1971 à/to 1973 incl.St-Placide.1964 à/to 1967 incl., 1969, 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Rouyn.1964,1966 à/to 1968 incl., 1970 et,and 1973 incl.Rosemère.1964 à/to 1973 incl.Côte St-Luc.1964 à/to 1969 incl., 1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 et/and 1973 St-Laurent.1971, 1972, 1973 Laval-des-Rapides.1964 et/and 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl. 8202 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 197k, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed BEAUHARNOIS PALACE HOTEL INC.82840 ELAINE BEDARD INSTITUTE LTD 78506 PAUL BEDARD INC.73502 ROLAND BEDARD INC.73503 BEE SPORTSWEAR LTD.78664 BEL TOY NOVELTY INC.75758 DOMINIQUE BELANGER CONSTRUCTION INC.81725 BELLEMARE & ST-ONGE INC.79818 BELLE-VILLE ELECTRIQUE INC.78314 BELLEVUE TAVERN INC.81428 BELMONT CLEANERS LTD.82664 BEN BENOIT INC.77615 BERNARD ELECTRIQUE INC.78019 BLUE SEAL STABLES INC.79257 H.BOIVIN CONSTRUCTION INC.47219 BOUDREAULT & GAGNON MEUBLES INC.81521 BOULEVARD SURGICAL CLINIC INC.73423 Beauharnois.Montreal.Québec.Fort-Chambly.Montreal.Montreal.Pointe-aux-Trembles Montreal.Beauport.Montreal.Montreal.Montréal.Brossard.Montreal.Québec.St-Félicien.Montreal.1973 .1964 à/to 1973 incl.1966.1971.1973 .1970 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1973 .1967, 1971, 1972, 1973 .1967 à/to 1973 incl.1973 .1967 à/to 1973 incl.1966, 1969, 1972, 1973 .1964 à/to 1973 jncl.DAMIEN BRAIS & FILS INC.79406 BRASSIERE JOUVENCE INC.80531 BREUVAGES HEROUX INC.75460 BRIERE ET DESROCHERS INC.77403 LAURENT BRODEUR INC.73424 C.I.B.C INC.77726 C.P.H.MECHANICAL INC.81876 C.Z.DEVELOPMENT CORP.71458 Notre-Dame-de-Stan-bridge St-Jérôme.Grand'Mère.Grande-Ile.Québec.St-Michel.Montreal.Montreal.1964, 1965, 1969 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1959 à/to 1973 incl.1973 1964, 1968 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1965 à/to 1967 incl., 1973 1965, 1972, 1973 1972 et/and 1973 1967 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n\" U 8203 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed CALOIL INC.73964 LES CAMIONNEURS UNIS VICTORIA INC.76763 THE CAMPUS DRIVE-IN & RESTAURANT LTD.75663 CAN-AM INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP.84266 CAPLAN-ZUNINO FLOWERS LTD.75913 CARETTE & GILBERT INC.80992 CARON & MORIN INC.78214 CAT'S DEN INC.78668 CENTRE D'ACHATS METHOT INC.82674 CENTRE CULTUREL DE GRAND'MERE INC.81143 LE CENTRE DE LOISIR DU LAC DE L'EST 77907 LE CENTRE DE LA MAISON MODERNE INC.79281 CENTRE NATIONAL BEL-AIR LTEE.78216 CENTRE DE NOURRITURE ST-LAURENT INC.42031 CENTRE DE SKI MONT SHICKS-SHOCKS INC.81530 CERAMIQUES DES MONTS INC.80539 PIERRE CHARBONNEAU INSURANCE INC.81035 CHARLES HOTEL INC.68289 JEAN-LOUIS CHASSE INC.79907 CHATEAUNEUF RESTAURANT INC.78673 CHEZ L.CORN ELI PIZZA & SPAGHETTI INC.80204 CHICHEN-ITZA CORPORATION.80764 CHOMEDEY CATERERS INC.81148 LA CIE ALCARRO INC.78332 LA CIE DE BOIS DE CAU8APSCAL INC.75285 Montreal.1972 et/and 1973 Victoriaville.1966, 1967, 1972, 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.St-Joseph-de-Beauce.1965 à/to 1973 incl.Auclair.1973 Montreal .1964, 1971 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Bon- 1966 à/to 1968 incl.Conseil 1970 à/to 1973 incl.Grand-Mère.1965 à/to 1973 incl.La Pocatière.1964, 1969 à/to 1973 incl.Val-d'Or.1964 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1964,1969,1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Cap-Chat.1965 à/to 1973 incl.St-Adèle.1966 à/to 1973 incl.Verdun.1972 et/and 1973.Iles-aux-Alumettes .1963 à/to 1973 incl.St-Romuald.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1966à/to 1968 incl.1970, 1973 Montreal.1970, 1971, 1973 Chomedey.1967.1971 à/to 1973 incl.Québec.1973 Amqui.1964, 1967 à/to 1973 incl. 8204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1971, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LA CIE DE GESTION LEVESQUE LTEE.75770 LE CINE THEATRE DU SEMINAIRE DE STE-THERESE INC.81389 LE CLUB AUTOMOBILE CORVETTE (QUEBEC) INC.81536 CLUB CHASSE ET PECHE ST-LUC.74979 CLUB CIVIL 57 INCORPOREE.77411 CLUB D'HIVER DE HULL INC.54448 CLUB RAYMOND INC.81885 LE CLUB SOCIAL COLOMBIEN DE CHICOUTIMI INC.61947 CLUB SPORTIF DION.78835 LE CLUB DE YACHT LE RELAIS INCORPORE.81392 COINEX MANUFACTURING COMPANY LIMITED.76065 COLONIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INC.78518 COMITE DES CITOYENS PROPRIETAIRES DE DRUMMONDVILLE INC.56417 COMITE DES LOISIRS ST-ALPHONSE DE GRANBY INC.76066 LE COMITE SPORTIF DAUTEUIL .79288 LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE FRANÇAISE INC.77026 LA COMPAGNIE MINIERE DEMFONTAINE LTEE C 78520 (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 20 LES COMPAGNONS DE L ACTION.74983 CONCORD-ROSS CORP.77079 CONSEIL DE BIEN-ETRE DU QUEBEC.79831 CONSOLIDATED WIPING PRODUCTS LTD.77911 CONSTRUCTION D.M.LIMITEE.82873 CONSTRUCTION GUY VILLENEUVE LTEE.80550 CONSULTANTS PROFESSIONNELS (QUEBEC) INC.106722 Roberval.Ste-Thérése.Montréal.St-Joseph-de-Beauce- Montréal.Hull.Levis.Chicoutimi.Pont-Rouge.St- Joseph-de-Sorel.St-Jean.Montreal.Drummondville.St-Alphonse-de-Granby .Auteuil.Montréal.St-Jérôme.Québec.Montreal Montréal.Montreal.St-Eustache.Hull.Québec.1964 à/to 1967 incl., 1973 1965 à/to 1967 incl.,1972, 1973 1965 à/to 1973 incl.1973 1964 à/to 1973 incl.1962, 1964,1968, 1972, 1973 1966 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1964, 1966, 1968 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1964, 1973 1973 1963 à/to 1973 incl.1964, 1966, 1967 à/to 1969 inc!., 1971 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973.1964 à/to 1966 incl.,1970 1971.1973 1973 1964, 1966, 1973 1971 et/and 1973 1964 à/to 1973 incl.1965,1969 à/to 1973 incl.1967, 1972, 1973 1972 et/ and 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, : novembre 1974, 106' année, n° 44 8205 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1971 àjto 1973 incl.Montréal.1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Fort-George.1965, 1972, 1973 Québec.1964 à/to 1973 incl.Lachute.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1967 incl., 1973 St-Michel.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.St-Laurent.1964 à/to 1966 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967.1973 Montreal.1970, 1972, 1973 Longueuil.1963 à/to 1973 incl.Jonquière.1971 à/tol973 incl.Ste-Martine.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Victoriaville.1964 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.St-Eustachc.1965 à/to 1973 incl.Joliette.1971 et/and 1973 Drummondville.1973 Val-Alain.1969 à/to 1973 incl.Victoriaville.1971 à/to 1973 incl.Doilard-des-Ormeaux.1964 à/to 1966 incl., 1973 Nom de la compagnie Name of the company CONTINENTAL DINETTES LTD.81893 COPOLOFF INSURANCE AGENCIES INC.81158 CORGEMINES LIMITEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 74984 CORONA DEVELOPMENT CORPORATION.79682 LA CORPORATION DE L'HOPITAL STE-THERESE DE L'ENFANT-JESUS DE FORT GEORGE 84502 LA CORPORATION D'IMMEUBLES EUREKA LTEE.77417 CORPORATION DES PROPRIETAIRES DE TAXI DE LA VILLE DE LACHUTE 87204 CREDO MINING LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY).80907 CREME GLACEE (GELATERIA SICILIANA INC.).72925 CROSS COUNTRY SALES CORP.74989 DE NAND INC.78965 DE SOLA MORTGAGE CORPORATION.81763 DELL-FRANCO INC.73555 DESCHALETS ELECTRIQUE CIE LTEE.53760 PAT DESCHENES & FRERES LTEE.80432 DESGROSEILLERS LUMBER INC.82886 DESIGN TECHNICS LTD.78060 LE DEVELOPPEMENT D'ARTHABASKA INC.79427 LE DEVELOPPEMENT DES DEUX MONTAGNES INC.80558 DEVELOPPEMENTS LAC-DES-MONTS INC.78967 DEVELOPPEMENTS LAPERO INC.77743 LES DEVELOPPEMENTS VAL-ALAIN INC.111246 DEVELOPPEMENT VICTORIAVILLE INC.76079 DOLLARD HARDWARE LTD.79430 8206 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Nom de la compagnie Name of the company DOMAINE DU SKI MONT-BRUNO INC.81165 DORMIDA INC.75204 P.E.DRAPEAU INC.76082 DUFAULT A ASSOCIES INC.80355 DUMONT & DUGUAY INC.50546 DURIC LIMITEE.79188 DURION INC.79434 EARLE DRESS & SPORTSWEAR LTD.74998 THE EASTERN FRUIT CO.LTD.80659 ECOLE DE KARATE DE MONTREAL INC.103433 LES ECURIES ARGENTEUIL INC.81169 LES EDITIONS SURBOUM INC.78069 EMBASSY SPORTSWEAR MFG.CO.79438 EMPIRE MILLING CO.LTD.77095 ENSEIGNES OMEGA SIGNS INC.58350 LES ENSEMBLES UNISPORTS INC.129904 LES ENTREPRISES ALBERT LTEE.79559 LES ENTREPRISES CEMA INC.79439 ENTREPRISES DESAULNIERS LTEE.79094 LES ENTREPRISES DU DOMAINE DES LACS RAYMOND LTEE 79440 LES ENTREPRISES G.A.L.LTEE.82895 LES ENTREPRISES GREGO INCORPOREE.75602 LES ENTREPRISES HORTON INC.79297 LES ENTREPRISES J.L.DINEL LTEE .76808 Adresse Rapports non produits Address Returns not fil'd St-Bruno-de-Montar- 1967, 1973 ville.Montréal.1972 et/and 1973 Victoriaville.1966, 1967, 1972, 1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Sept-Iles.1960 à/to 1973 incl.Drummondvilie-Sud- 1964 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1964 à/to 1968 incl., 1972, 1973 Montreal.1964 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1968 à/to 1973 incl.St-André-Est.1966 à/to 1968 incl.1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 et/and 1973 Montreal.1964 à/to 1967 incl., 1969, 1971 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1961 à/to 1973 incl.Montréal-Nord.1972 et/and 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Matagami.1964 à/to 1973 incl.Asbestos.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1964.1967, 1969, 1970, 1973 Montréal.1965, 1966, 1970 à/to 1973 incl.Chomedey.1973 Ste-Clothilde-de-IIorton.1964, 1970 à/to 1973 incl.St-Michel.1967 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, s novembre 1971, 106' année, n° U 8207 Nom de la compagnie Same of the company LES ENTREPRISES JALIAN INC.78845 LES ENTREPRISES L.GAGNE INC.54030 LES ENTREPRISES LAMBERT INC.81017 LES ENTREPRISES LEVIS INC.75385 ENTREPRISES MAISONNEUVE INC.80781 LES ENTREPRISES NAUTIQUES DE L'ILE GOYER LTEE 81771 LES ENTREPRISES RIVAROLE LTEE.80237 ENTREPRISES ROUVILLE INC.47321 LES ENTREPRISES URBAINES LTEE.75942 EPICERIE TRAVERSY INC.73572 EPSILON INVESTMENTS LIMITED.78365 EQUIPEMENT & PREVENTION D'INCENDIE SAG.LTEE 80358 LES ETABLISSEMENTS DUBOIS LTEE.74906 EVE'S DELICATESSEN A SNACK BAR INC.74907 EXCEL INVESTMENT CORP.87716 LES EXPERTISES SHEFFORD INC.78851 F.W.E.STAPENHORST INC.93762 B.FABIEN INC.64304 FARRELL ENTERPRISES INC.80439 FASHION FURNITURE INC.77214 FATIMA CONSTRUCTION INC.77100 FERMA IMPORT & EXPORT INC.75732 FERRONNERIE BELMONT INC.79841 LA FERRONNERIE CARTIER INC.82906 FLEURISTE 4-SAISONS INC.75390 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Sherbrooke.1964, 1965, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Hauterive.1960 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Bon- 1973 Conseil.Chomedey.1964 à/to 1973 incl.Duvernay.1973 St-Joseph-de-Chambly.1965, 1967 à/to 1973 incl.Hull.1968 à/to 1973 incl.Marieville.1959 à/to 1962 incl.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970.1972,1973 Pierreville.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1965 à/to 1967 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Granby.1964, 1966 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1968.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Laval-des-Rapide».1966.1967.1969.1973 Montreal.1966 à/to 1969 incl.1972.1973 Sherbrooke.1971 et/and 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl. 8208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 197A, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed FLYING EXECS ASSOCIATES.77352 FONTAINE BLEAU ASSOCIATES LTD.78084 FRATELLI J.INC.79198 FRED-EL REALTIES INC.81777 FRONTIER INN INC.73369 G.M.L.CONSTRUCTION INC.81032 GAGNON & BEAULIEU INC.54612 GAGNON SPORTSWEAR INC.79704 GAGNON VALKUS INC.77218 GAIL CONTRACTING & MFG INC.77639 GALLANT FASHIONS INC.79490 GANA COMPANY LTD.78862 GARAGE LA POINTE INCORPORE.46960 GARDE IMMACULEE CONCEPTION INC.75016 GASPEX MINES LTD (NO PERSONAL LIABILITY).79201 LOUIS-G.GAUDREAU & FILS INC.81309 GESCO LIMITEE.81037 GIOVANNI CONSTRUCTION LTEE.79187 Chomedey.1966, 1967, 1972, 1973 Montreal.1964 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1964, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Hemmingford.1966, 1968 à/to 1970 incl., 1972, 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Septrlles.1962 à/to 1973 incl.Warwick.1964, 1966 à 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Westmount.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Arvida.1966 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1964.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1968, 1969, 1973 Montréal.1973 GIRARD & FILS LTEE.St-Félicien.1965, 1967, 1973 81183 GLENWOOD WATER SERVICES INC.Aylmer East.1969 à/to 1973 incl.80049 GLOBAL HOLDINGS INC.81781 S.GOLDSTEIN (CANADA) LTD.77227 .Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.A£T\u201eHUR GRANDCHAMP LIMITEE.Louiseville.1964 à/to 1973 incl.73899 WALTER GREEN INVESTMENT CORP.75395 GREENROSE CONSTRUCTION CORP.75492 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, novembre 1971, 106' année, n° il 8209 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Georges d'Henryville 1964 à/to 1973 incl.Montréal.1969 et/and 1973 Montreal.1959 à/to 1962 incl., 1964 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1962 à/to 1973 incl.Montreal.1967 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1968.1970 à/to 1973 incl.Montréal Nord.1972 et/and 1973 Montréal.1966.1967, 1973 Deauville.1966.1968 à/to 1973 incl.St-Félicien.1969, 1972, 1973 La Malbaie.1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Beauharnois.1968 et/and 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Roberval.1966.1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1965,1966,1973 Duvernay.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Kénogami.1967.1972, 1973 St-Raymond.1971 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse-Ouest.1967 à/to 1973 incl.Victoriaville.1964, 1966, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1964, 1968 à/to 1973 incl.St-Félicien.1973 Nom de la compagnie Name of the company GREGOIRE ET CIE LTEE.36921 GROSSISTE EN PLOMBERIE IDEAL LTEE.80922 GUARDCREST REALTY & LAND CO.LTD.46054 HARRY'S MEAT MARKET INC.82926 HAWKEYE EQUIPMENT CO.LTD.57613 HEART INVESTMENTS LTD.76169 HERMAC INVESTMENTS LTD.77643 HOMBER CONSTRUCTION CORP.77112 HOPITAL DES RECOLLETS INC.41474 HOPITAL STE-RITA INC.82724 HOTEL BEAU-SITE INC.81316 HOTEL BELLEVUE (ST-FELICIEN) LTEE.77474 HOTEL HOVINGTON INC.76830 LES HOTELS MAPLE-GROVE INC.81427 HOTEL PRESIDENT INC.74169 LES IMMEUBLES AVICOLES LTEE.81923 LES IMMEUBLES B.G.B.LTEE.80682 LES IMMEUBLES DULABEC LTEE.78100 IMMEUBLES LA LUMIERE INC.78992 LES IMMEUBLES LEVASSEUR LTEE.89488 LES IMMEUBLES MANU LIMITEE.80461 LE8 IMMEUBLES PELLETIER LTEE.81044 IMMEUBLES PROVENCHER LTEE.78245 LE8 IMMEUBLES REPUBLIQUE INC.78871 LES IMMEUBLES ROLA LIMITEE.76734 8210 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 197A, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Addrese Rapports non produits Returns not filed IMMEUBLES ST-MAURICE LTEE.55434 IMMEUBLES VANDA INC.75808 IMPERIAL FURNITURE SHOWROOMS INC.68746 IMPRIMERIE FARNHAM INCORPOREE.80452 INDUSTRIAL BLUE COLLAR LTD.77236 INSTITUT AERO-TECH DE MONTREAL INC.71738 INSTITUT CURE-LABELLE.58043 L'INSTITUT FAMILIAL.213268 L'INSTITUT SCIENTIFIQUE FRANCO-CANADIEN .78594 INTERFORM (CANADA) LIMITED.45864 INTERNATIONAL INDUSTRIAL SUPPLIES LIMITED.73379 LES INVESTISSEMENTS MIDAS LTEE.90019 IROQUOIS PETROLEUM CO.LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) 73905 ISABAL LTEE.81463 Trois-Rivières.1960 à/to 1973 incl.Montréal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1963 à/to 1973 incl.Farnham.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 St-Jérôme.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1947 à/to 1973 incl.Montréal.1932 à/to 1962 incl.1964, 1969 à/to 1973 incl.Westmount.1959 à/to 1973 incl.Thetford Mines.1973 Montréal.1966 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 et/and 1973 Montréal.1973 JSLAND PRODUCTS COMPANY LTD.Iles-de-la-Madeleine.1957 à/to 1973 incl.40688 ITAL CANADA INTERNATIONAL SOCCER CLUB INC.Montreal.1965 à/to 1973 incl.81430 ITAL FLOOR FINISHERS CO.LTD.68549 J.J.CONSTRUCTION LTEE.81431 J.M.CO.LTD.73651 J.P.MOTOR INDUSTRIES LTD.79002 LA JEUNE CHAMBRE DE GAGNON INC.Gagnon 102781 LA JEUNE CHAMBRE DE LACHUTE INC.76735 LES JUTES VICTORIA INC.81607 KEYSTONE ESTATES CORP.73444 LaSalle.1963 à/to 1973 incl.Montr«al.1965.1966.1968 à/to 1973 incl.Norandtt.1970, 1972, 1973 St-Laurent.1964 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.Lachute.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.i965| i969 à/to 1973 inc, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.novembre 1971,, 106' année, n° U 8211 Nom de la compagnie Name of the company KEYSTONE MORTGAGE CONSULTANTS LTD.78718 L.G.AUTO REPAIR INC.82993 LAC CLAIR LIMITEE.80804 LAFLAMME & FRERE (1964) INC.81583 JEAN P.LAFRANCE INC.79743 LANGELIER TRANSPORT LIMITEE.76979 LANTHIER A FRERES LIMITEE.77120 ARMAND LAPOINTE INC.37270 J.A.LAPOINTE T.V.INC.73907 L APPEL INC.73959 NORMAND LARRIVEE INC.82740 LAURENTIAN SALT COMPANY LTD.73447 LA VALLEE & L'HEUREUX INC.78116 THE LAWSON FURNITURE CO.LTD.80274 JEAN-LOUIS LECOURS INC.82953 A.L.LEGAULT CONSTRUCTION LTEE.76741 L'ELEGANTE (MATANE) LIMITEE.75142 LEMIRO INC.81909 LEVASSEUR AUTO LTEE.79213 LIGUE DES LAURENTIDES ¦ JUNIOR B r.82967 LA LIGUE DES PROPRIETAIRES DU LAC L'ACHIGAN,.81693 LIGUE DES PROPRIETAIRES DU VILLAGE DES ESCOU- MINS 81933 LOMIC LTEE.75317 LOYER & FRERES, CIE LTEE.80817 M.B.COATINGS INC.77248 Adresse Rapports non produits Address Return) not filed Montreal.1964.1965, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Eustache.1966, 1967.1969 à/to 1971 incl., 1973 St-Félicien.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Chandler.1971 et/and 1973 Montréal.1964, 1966, 1972, 1973 Québec.1957 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Sillery.1965,1969,1973 Trois-Pistolcs.1965, 1966.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à'to 1973 incl.Lauzon.1967 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1964 à/to 1973 incl.Matane.1973 Val-d'Or.1973 Kénogami.1964, 1968, 1971 à/to 1973 incl.Ste-Thércae-de-Blain- 1966 à/to 1973 incl.ville Lac L'Achigan.1966.1969, 1971 à/to 1973 incl.Escoumina.1966 à/to 1973 incl.Jonquière.1964 à/to 1973 incl.St-Marcelline-de- 1965 à/to 1973 incl.Kildare Montreal.1964 à/to 1973 incl. 8212 QUÉBEC.OFFICIAL GAZETTE, November S, 1971, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed M & G HOLDINGS LTD.78720 MAGASIN A RABAIS NORDIC INC.81599 MAISON DURY LTEE.80015 LA MAISON MORAD LTEE.77131 MAISONNEUVE MINES INC.(NO PERSONAL LIABILITY).84958 ARMAND MAJOR INC.80933 MAJOR & FILS COMPAGNIE LIMITEE.81802 MARCHE CALDER INC.81938 MARCHE CHAMPION INC.64088 MARCHE ORSA1NVII.LE INC.75318 MARCHE STE-LUCIE INC.79023 MARELLE INC.80281 MARIEVILLE FURNITURE MFG.LTD.37753 LES MAJORETTES DES BOIS FRANCS.76861 MARNEL ENTERPRISES INC.49829 LES MAROQUINERIES DU QUEBEC INC.109146 MARSEIL CORPORATION.81065 MCKINNON AUTO ELECTRIC LTD.82974 MELVILLE PRESS LIMITED.80698 METRO STORE FIXTURES INC.78732 METROPOLITAN WATER FILTRATION INC.73450 GUY MICHAUD & ASSOCIES INC.82756 MILLER BROS CONSTRUCTION LTD.75833 MOBILIER MODERNE (1963) LTEE.73680 MONT ST-JOVITE INC.76864 Montreal.St-Jérôme.St-Jovite.La Pocatière.Montreal.Weir.Jacques-Cartier.Montréal.Montréal.Orsainville.St-Michel.Trois-Rivières.Marieville.Plessisville.Montreal.Marieville.Chomedey.Chandler.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal.St-Michel.1964 et/and 1973 1972 et/and 1973 1965, 1967, 1972, 1973 1965, 1968 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1965, 1966, 1970 à/to 1973 incl.1965.1966, 1969, 1970, 1972, 1973 ,.1972 et/and 1973 .1962 à/to 1973 incl.1973 1964.1966, 1967, 1969, 1971, 1973 1964 à/to 1973 incl.1957 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1966, 1967.1969.1971 A/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1971 incl.1973 1964 à/to 1973 incl.1963 à/to 1973 incl.1965, 1971 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1973.1964, 1966 à/to 1973 incl.St-Jovite. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971, 106' année, n\" U 8213 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1967, 1972, 1973 Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1967 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Terrebonne.1966, 1968 à/to 1973 incl.Pickanock.1964 et/and 1973 Venise-en-Québec.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1968 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Alphonse.1966 à/to 1973 incl.Montréal-Nord.1964, 1966, 1968, 1970, 1973 St-Jérôme.1966,1967,1972.1973 Montréal.1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Rouyn.1973 Notre-Dame-de-Stan- 1964 à/to 1973 incl.bridge.Montreal.1964.1965,1967.1973 Ste-Foy.1969 et/and 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.St-Apollinaire.1964 à/to 1973 incl.Cap-Santé.1964.1967, 1969, 1970.1972, 1973 Montreal.1973 Montréal.1966.1969 à/to 1973 incl.Nom do la compagnie Name of the company MONTREAL HUMAN HAIR CENTER INC.81226 MOR-CAL HOLDING CORP.75412 MORIEL INCORPORATED.80701 MOTEL ATTACHE LTEE.77142 MOTEL LE SOMMET INC.80285 MOTEL PAVILLON BLEU INC.79220 MOTEL QUARTIER LATIN INC.78896 MURRAY'S M.& R.ENTERPRISES INC.78738 LAWRENCE MYERS INC.76131 N 4 I DRY CLEANERS CO.75635 NASA CORP.46879 NICAL BONBONS INC.90283 NIVOSE LTEE.78739 NORDIX LIMITEE.77145 NOR-SARRE EXPLORATIONS MINIERES LIMITEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 81611 TILFORD NEMOUR LTD.111637 NOSOV-PEDSKALNY (QUEBEC) LTD.80028 NOTRE-DAME FEED SERVICE INC.79605 NU-FILM INDUSTRIES LTD.75838 O.P.L.ST-MATHIEU.73922 OBIE'S MEAT INC.27040 L'OEUVRE DES LOISIRS DE SAINT-APOLLINAIRE.77508 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE CAP-SANTE INC.79322 OLD HICKORY BARBECUE MACHINES LTD.75842 OPTIMA INC.79953 8214 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November g, 197A, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed OSMINGO HOLDINGS CORP.77367 OTTER LAKE INVESTMENTS LTD.80030 GUY OUELLET.INC.77510 ROGER OUELLET INC.80379 PALERMO FURNITURE INC.77151 PANISA DEVELOPMENT INC.81075 PAPETERIE BREL LIMITEE.81076 PARR VENTILATION LTD.58276 PARTHENAIS BUILDING CORP.75846 PAUL & SONS WINDOW CLEANING INC.73688 LE PAVILLON BREBEUF LTEE.51412 LE PAVILLON NORMANDIE INC.79336 PEAK ELECTRONICS LTD.81235 PEGI CONSTRUCTION LTEE.78900 PERFECTION PLUMBING AND HEATING CO.80705 PERRIWICK TRADING CO.LTD.81237 PETER PAN PASTRY SHOPPE INC.81614 PETROLES BIRON INC.80034 THE PHOENIX CLUB.78566 PIEKOUAGAMI MINING INC.75640 PIERRE CONSTRUCTION LTEE.73690 LE^PIGEON DARGILE (RIMOUSKI) INC.PILON & FILS INC.73929 R.& G.PILON INC.79327 81079 GABLES NURSING HOME LTD.Montreal.Hull.Québec.St-André.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal .Montreal.Montreal.Montréal.Ste-Thérèse.Montreal.Lyster.Montreal.Westmount.Montreal.Montréal.Westmount.Roberval Joli Village.Rimouski.St-Timothée.Montréal .Cowansville.1964, 1968 à/to 1973 incl 1966, 1967, 1970, 1973 1964 et/and 1973 1969 et/and 1973 1968 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1968.1969, 1973 1964 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1964.1967.1968, 1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1966, 1971, 1973 1972 et/and 1973 1965, 1967, 1969 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1973 1968 à/to 1973 incl.1964 à/to 1973 incl.1964, 1972, 1973 1964, 1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8215 Nom de la compagnie Name of the company PISCICULTURE DE VAL-DES-BOIS INC.77614 PLACE CHAMPLAIN CORP.77370 PLACE LES ECORES INC.81464 PLACEMENTS B.G.M.LTEE.81337 LES PLACEMENTS CARMICHAEL LTEE.80292 LES PLACEMENTS CONTREVILLE INC.81616 LES PLACEMENTS HAMEL LTEE.80296 LES PLACEMENTS INDUSTRIELS DU QUEBEC LIMITEE.82998 LES PLACEMENTS JACOU INC____ 76527 PLACEMENTS LE GARDEUR INC.78902 PLACEMENTS MERICI INC.74937 LES PLACEMENTS MOBERGE INC.78752 LES PLACEMENTS MONTIGNY INC.77157 LES PLACEMENTS ROUTHIER LTEE.81619 LES PLACEMENTS SIFAR INC.79489 LES PLACEMENTS TERBEC LTEE.80945 LES PLACEMENTS VILLE-MARIE LIMITEE 78904 PLASTIC SERVICES 4 DIES LTD.73694 PLATA HOLDINGS INC.81952 PLOMBERIE MICHEL INC.78269 L.POIRIER TRANSPORT INC.81243 POULIN 4 RODRIGUE INC.78753 PRINCESS LAND 4 HOUSING CORP.80947 A.E.PRITCHARD LTD.80039 PRODUITS ALIMENTAIRES CHANTECLER INC.81625 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Addrttt Returns not filed Val-des-Bois.1966.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 et/and 1973 Duvemay-.1966, 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1966,1971,1973 Giffard.1973 Ste-Foy.1968 à/to 1973 incl.La Sarre.1965 à/to 1973 incl.Ville de Laval.1965.1966, 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Repentigny.1967 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1964 à/to 1973 incl.Québec.1973 Montréal.1964.1966.1973 Boucherville.1973 Montréal.1964.1969, 1971.1973 Ste-Thérèse-Ouest.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968, 1970, 1973 St-Jean.1965, 1968 à/to 1973 ir.cl.Beauceville-est.1964.1966, 1968.1973 Montreal.1969 à/to 1973 incl.Kazabaïua.1971 à/to 1973 incl. 8216 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1971, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed PRODUITS D'ERABLES TUQUE ROUGE LTEE.73702 PRODUITS DE MER LES ESCOUMINS INC.71311 LES PRODUITS SANITAIRES FLEUR DE LYS LTEE.80612 PROTHESORAL LIMITEE.75199 LES PUBLICATIONS DE BEAUHARNOIS INC.77161 QUEBEC PHONOGRAPHS LTD.43115 QUINCAILLERIE HECTOR DURAND INC.75859 R.F.ELECTRONIC INC.81247 R & G ESTATES INC.79334 R.L.ELECTRO MACHINING INC.78152 PETER J.RACHMANN LIMITED 79780 RAMBLING TOURS INC .114483 RAYMOND & JEAN INC.75328 RED RIB STEAK HOUSE LTD 73935 REGAL DISTRIBUTION LTEE.82784 RELIURE CLASSIQUE INC.76149 RENAUD & FILS INC.56037 RENIL AVICULTURE INC.75738 RENLOWE CORPORATION.77165 REPRO-EXPRESS INC.81631 REPROX CORPORATION.77684 LEJRESTAURANT CASSE-CROUTE INCORPOREE.RESTAURANT LE SABRE INC.80843 RESTAURANT MEDITERRANEE INC.81250 RETEL ENTERPRISES INC.28224 St-Emile-de-Montcalm 1968 à/to 1973 incl.Les Escoumins.1963 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Beauharnois.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1958 à/to 1973 incl.Loretteville.1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1966, 1967.1973 Beaconsfield.1970 à/to 1973 incl.Chomedey.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1970 incl., 1972, 1973 Québec.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1973 St-Eustache.1961 à/to 1973 incl.Québec.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1973 St-Michel.1965 à/to 1973 incl.Saint-Laurent.1972 et/and 1973 Trois-Rivières.1964 à/to 1966 incl., 1968 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106- année, n° 44 8217 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name of the company Addreu Returns not filed RICHELIEU PROPERTIES INC.Hull.1964,1972 1973 77960 RIDGEWOOD CLEANING MAINTENANCE LTD.Westmount.1964 à/to 1973 incl 74944 RIVAL 5.10.15, $1.00 STORES INC.Chomedey.1964,1965.1966 79233 1969 à/to 1973 incl.RIVERVIEW HOTEL INC.Châteauguay.1964 à/to 1969 incl.79340 1973 RIVIERA SWIMSUITS LTD.Montreal.1964 à/to 1973 incl.77167 WILBROD ROBERT INC.Beauport.1967 à/to 1970 incl 79962 1973 MARC ROBITAILLE INC.Farnham.1964 à/to 1973 incl.76897 ROBLIN ENTERPRISES INC.Piedmont.1964 et/and 1973 79342 ROCKET PETROLEUM EXPLORATIONS LTD.Montreal .1961 à/to 1973 incl.55566 RONDEROSA CORPORATION.Westmount.1965 à/to 1973 incl.80614 ROPIN INC.Gatineau.1966 à/to 1969 incl.81968 1973 ROSEDALE HOMES & MORTGAGE INC.Montreal.1969 à/to 1973 incl.68898 RAYMOND ROY INC.Roberval.1971 à/to 1973 incl.86246 ROBERT ROY A ASSOCIES INC.Chomedey.1967, 1968.1973 80310 ST-BRUNO RIDING CLUB INC.St-Bruno.1968 à/to 1973 incl.75064 ST.CATHERINE'S DEPARTMENT STORE LTD.Montreal.1965 à/to 1973 incl.81835 FERNANDO ST-HILAIRE LIMITEE.Québec.1966.1967, 1973 78160 ST-MICHEL VALET SERVICE INC.St-Michel.1966 à/to 1973 incl.81343 STE-MARIE AIR SERVICE INC.St-Jérôme.1964 et/and 1973 79236 8ALAISON CARTIER INC.Montréal.1966, 1967, 1969 à/to 234793 1973 incl.SALONS FUNERAIRES DEMERS LTEE.Beloeil.1965 à/to 1973 incl.81475 LES SALONS FUNERAIRES GAUTHIER LTEE.Lauxon.1968 à/to 1973 incl.75541 SANO WORKEX LTD.Montreal.1973 80717 ?£5A-P * SURPLUS LTD.Montreal.1959 à/to 1973 incl.45305 SECURITE ABC INC.St-Michel.1971 à/to 1973 incl.78716 8218 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November s.1971, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company SERTEX INC.81969 SERVICE DE CONSTRUCTION DOMICILIAIRE LTEE____ 76909 SERVICE DE LIVRAISON G.LEMAY INC.118968 SERVICE DE LOCATION FIBRA INC.80313 SERVICE DES LOISIRS STE-GERTRUDE.78455 SERVICE SANITAIRE S.S.INC.75707 SHERBROOKE-CAVENDISH CORPORATION.77280 SHERIMCO INCORPOREE.81971 SI-BON FASHIONS INC.78921 SILHOUETTE HEALTH STUDIOS (NO.5) LTD.73474 SKINO INC.75648 SNOWDON.SAUVE, LTD.77376 SOCIETE FINANCIERE VENDOME LTEE____ 75212 SOCIETE DE GESTION NOTRE-DAME INC.79133 SOCIETE IMMOBILIERE BONIN LIMITEE.78280 SOCIETE IMMOBILIERE HABITAT LTEE 104031 LA SOCIETE LEGARE INC.76213 .LA SOCIETE DE PLANIFICATION MUNICIPALE INCOR- POREE 77694 SOCIETE RIALTO INCORPOREE.73945 .SOGETIM INC.81973 .SOPHIA RESTAURANT (ST.EUSTACHE) LTD.81261 SOREL STEAK HOUSE INC.77538 .SOUTH SHORE FUR & GARMENT STORAGE INC.ol642 SOUTH SHORE PAINTING INC.81348 .SPECIALITES DALVANIE, CIE LTEE 78464 .Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Salaberry-de-Valleyfield.1965 à/to 1967 incl., 1972, 1973 Duberger.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montréal-Nord.1964, 1968, 1971 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965, 1968, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1964,1966,1972,1973 Sillery.1963 à/to 1973 incl.Montreal.1968 et/and 1973 Montréal.1964 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Bon- 1964, 1967 à/to 1973 incl.Conseil.Montréal.1972 et/and 1973 Sainte-Foy.1968, 1972, 1973 Québec.1973 St-Vincent-de-Paul.1964 à/to 1973 incl.Québec.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Sorel.1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1971, 1973 St-Brunc-de-Montarvil!e 1965 à/to 1967 incl 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1964,1971,1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, novembre 1974, 106' année, n° 44 8219 Nom de la compagnie Name of the company SPEED-O-SET CORPORATION.75072 LIBERATO SPENSIERI LTEE.81097 STEEL FLANGE MANUFACTURING CO.LTD.79799 STEPHENSON COMPANY LTD.77801 LOU STERN SALES INC.78466 BUDDY STONE INC.79986 STUDIO DE DETENTE SAUNA INC.76437 SUNDAY HERALD PUBLISHING CO.73476 SUNSET FARMS LTD.80500 SUPER-POWER CLEANING & MAINTENANCE CO.75550 SURVIVAL SUPPLIES CO.LTD.77803 SWIRSKY CONSTRUCTION LTD.80322 SYSTCOMS LIMITEE.75715 TABLE D'HOTE INCORPOREE.76164 TALON ASBESTOS MINES LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 77699 TANOHURST INVESTMENTS LTD.76218 TECHNO-FILM SERVICES CO.LTD.79246 TELE-PUBLICITE INC.78470 TESSIER & TESSIER INCORPORE.77643 THEATRE PORT CARTIER INC.99389 J.J.THIBEAULT & FILS INC.75347 TILFORD NEMOUR LTD.111637 TIROIRS A DOUBLE USAGE LIMITEE.75873 TOITURE MAURICIENNE INC.79637 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1964 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montreal.1973 Montreal.1964.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969.1971, 1973 Montreal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1971 incl., 1973 Stanstead.1965 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Québec.1964.1969, 1970, 1972, 1973 Montreal.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1964 à/to 1973 incl.St-Joseph-de-Beauce.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1964 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Hull.1967,1972,1973.Port-Cartier.1968 à/to 1973 incl.St-Vincent-de-Paul.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Alma.1964 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine- 1964, 1972, 1973 x220 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Nom de la compagnie Name of the company TOP REALTY INC.80624 TRANS-CANAOA UNIFORM CO.LTD.79639 TRANSPORT LANCTOT LTEE.81845 JEAN-PAUL TREPANIER INC.76783 ESDRAS TOUSIGNANT INC.79065 TRI-LAND INVESTMENT CORP.81980 TRUITES LAURENTIENNES INC.76559 TURNBULL & SONS LIMITED.75718 U-DRIVE RENTALS LTD.81847 UNION DE FAMILLE DE STE-JEANNE-DE-CHANTAL.74993 ANDRE VACCARO CONSTRUCTION LTEE.82813 H.P.VAHADE FILS LTEE.78584 VENDEUSES AUTOMATIQUES CHAM PLAIN INC.235507 MARCEL VIAU LIMITEE.82817 VILLAGE HABITANT INC.80328 VILLE-MARIE MOTOR HOTEL LTD.79809 VOGUE BUCKLE INC.66309 VOSKO HOLDINGS INC.76879 .WATERLOO ARENA ASSOCIATION INC.73962 WATERMAN CANADA INC.81496 .DAVID WEST LIMITED.80331 .WINDSOR IMPORT CORP.77886 .XANTE PIZZA LTD.77978 .Le directeur du service des compagnies, as»d8-o Pierre Desjardinb.58868-0 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Laurent.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1973 incl.Neufchàtel.1965, 1966, 1973 Sherbrooke.1967, 1970 à/to 1973 incl.La Tuque.1964, 1967, 1970.1973 Montreal.1965 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Waterloo.1964,1968 à/to 1970 incl.1972.1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1964 à/to 1966 incl.1973 Montréal.1965 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Ste-Agathe-des-Monts.1964, 1972.1973 Mount Royal.1968 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967.1969 à/to 1973 incl.Knowlton.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Drummondville.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964.1971 à/to 1973 incl.Waterloo.1964 à/to 1973 incl.St-Lambert.1966.1967, 1973 Chomedey.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1966 à/to 1973 incl.Montreal.1964, 1972, 1973 n- , Ç'.?'\"^ DEMARDIMê, Director of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1971, 106- année, n° U 8221 Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies Name of the companies Dissolution Date Gazette officielle No Official Gazette No.CLUB INDIEN.\t13\t10\t73\t41 LE DOMAINE DE L'ETOILE INC.\t13\t04\t74\t15 EQUIPE PASTORALE DE L'IMMACULEE-CONCEPTION.\t12\t01\t74\t2 SOCIETE HISTORIQUE DE DRUMMONDVILLE.\t12\t01\t74\t2 WRIGHTVILLE BUILDING SUPPLIES CO.LTD.\t17\t08\t74\t33 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation.Le directeur du service des compagnies, 58868-0 Pierre Desjardinb.Lettres patentes annulées Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4, 5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont annulées à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de ce deuxième avis.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins, 58868-0 Director of the Companies Service.Letters Patent Annulled The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow are cancelled from the date of the publication in the Official Gazette of this second notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date A.& A.INVESTMENT CO.INC.60138 A.A.C.EXPRESSO COFFEE MACHINES INC.61083 ABRI NUCLEAIRE DE QUEBEC LTEE.62997 AERODROME MONTREAL INTERNATIONAL AUTOBUS ET TAXIS INC.59771 L'AGENCE LUMEN INC.64623 AIN ENTERPRISES INC.76039 ALLIANCE FRANÇAISE (ST-GEORGES, BEAUCE) INC.60831 ALROC CONTRACTING LIMITED.60633 LES EMBASSADRICES DE SHAWINIGAN INC.60142 ANGA INVESTMENT CORP.61706 Montréal.27 04 1961 Montreal.23 06 1961 Québec.26 10 1961 Dorval.22 03 1961 Montreal.16 01 1962 Montreal.05 12 1963 Ville St-Georges.02 06 1961 St-Eustache.09 05 1961 Shawinigan.18 04 1961 Outremont.16 06 1961 8222 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1971, Vol.106, No.11__ Adresse Incorporation Addreat Date St-Laurent.15 01 1962 Montreal.07 08 1961 Cap-de-la-Madeleine.07 12 1961 Chambly.12 12 1961 Drummondville.30 10 1961 Loretteville.05 12 1961 Ste-Thérèse.29 12 1961 Hull.12 12 1961 Charlesbourg.24 09 1961 Trois-Rivières.12 10 1961 Montreal.25 07 1961 Westmount.16 06 1961 Montreal.09 11 1961 St-Romuald.15 09 1961 Montreal.25 06 1970 Hull.13 09 1961 Montreal.09 01 1962 Alma.03 06 1958 Saint-Georges.27 09 1971 Dorval.06 03 1961 Chomedey.13 07 1961 Montreal.29 12 1961 Montréal-Nord.31 07 1961 Nom de la compagnie Name of the company ANVIL BUILDING CORP.64624 AQUA MINING CORPORATION LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 61708 ASSOCIATION ATHLETIQUE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE NORTON 62872 ASSOCIATION DES CITOYENS DE CHAMBLY INCORPOREE 64501 ASSOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU CENTRE DU QUEBEC 63016 L'ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE GANTS DE LA PROVINCE DE QUEBEC 63440 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE STE-THERESE EN HAUT 64368 L'ASSOCIATION RECREATIVE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.62993 L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHARLESBOURG.61911 L'ASSOCIATION DES TAVERNIERS DU TROIS-RIVIERES METROPOLITAIN INC.62816 ATLANTIC PRODUCTS COMPANY LIMITED.62307 ATLAS DEVELOPMENT INC.61296 ATLAS SHOULDER PADS OF CANADA LTD.63544 AUBERGE VIEUX-MOULIN ST-ROMUALD INC.62754 AUTO-CONFORT R.INC.119306 BM DEVELOPMENTS (QUEBEC) LIMITED.62309 BARMART LTD.64507 BEAU LAC CONSTRUCTION LIMITEE.44168 BEAUCE VOYAGES INC.130347 .BEAVER INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD 69466 .REAL BENOIT EXCAVATION LTEE., , 62339 .BIORHYTHMIC CHARTS OF CANADA INC 64509 .M.BIZIER INC .62311 . GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 197A, 106' année, n° 44 8223 Adresse Incorporation Address Date Malartic.14 02 1962 Montreal.16 08 1961 Joliette.17 12 1965 Québec.22 03 1961 Montréal-Est.27 11 1970 Montreal.26 05 1961 Melocheville.06 07 1961 Montréal.19 06 1961 Montréal.22 02 1961 Ste-Thérèse-Ouest.18 03 1965 Trois-Rivières.17 10 1963 Montreal.24 09 1956 Laval.20 08 1968 Montreal.28 11 1952 Montreal.01 03 1968 Dorval.07 10 1968 Montreal.06 12 1958 Ste-Thérèse.10 03 1965 Montreal.27 09 1961 Duvernay.28 06 1962 Baldwin.29 02 1962 Rivière-du-Loup.13 03 1968 St-Sulpice.10 02 1967 Québec.24 01 1969 Montréal.15 06 1961 Nom de la compagnie Name of the company BLANCHETTE & PLANTE LIMITEE.65266 BOMAC BUILDING CORP.62314 J.EDOUARD BOUCHER.LTEE.89325 P.& M.BOUCHER INC.60108 BRAY CONSTRUCTION LTD.122155 BRIGHTON PRESS INC.60695 F.BRUNET & SONS INC.62145 GERARD BRUNET INC.62144 BUANDERIE DE MONTIGNY INC.59918 BUFFET LAPERRIERE INC.84473 CABARET AUX FLAMMES INC.74877 CAMBRIDGE PRESS LIMITED.37809 CAMPING & SPORTS MODERNES INC.105831 CAPITOL BUILDING CORPORATION.26409 CARBITCO LTD.102890 CARDINAL SPORTS INC.107053 CARLTON INVESTMENTS INC.46318 GERRY CARON INC.84477 CELL-ROCK INC.63047 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VILLEGIATURE DUVERNAY INC.67064 LE CENTRE DES LOISIRS DE BALDWIN INC.64139 CENTRE RECREATIF ST-FRANÇOIS-XAVIER INC.103142 LES CHALETS BASSO INC.96040 LE CHALET DU TRICOT INC.108891 CHAPIRE INC.61116 8224 QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, November S, 197!,, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date CHATCO INC.60703 CHATEAU STEEL CORPORATION LTD.69796 CHEVALIERS D'IBERVILLE INC.60836 CHEZ PIERRE & CARLO INC.102661 CLOVERDALE PARK TENANTS ASSOCIATION INC.63451 CLUB ART ET DANSE DE LA REGION DE L'AMIANTE.63057 LE CLUB DE BASEBALL (LES INDIENS DE QUEBEC INC.).61587 CLUB DES 600.64136 CLUB DE GOLF DE CARLETON INCORPOREE.59480 CLUB NAUTIQUE DU LAC BROMPTON INC.68128 CLUB ST-ATHANASE.126622 CLUB SPORTIF AMIANTE INDEPENDANT INC.64399 LE CLUB DES VOYAGEURS D'AUTOS-NEIGE DE LA VALLEE DE LA GATINEAU 10i',5S4 CLUB DE YACHTING D'AMOS INC.62168 LE COMITE INDUSTRIEL ET DE DEVELOPPEMENT DU GRAND ST-GEORGES INC.63068 COMITE DES LOISIR8 DE VAL MAURICIE INC.63302 LA COMPAGNIE BELLE VUE INC.62613 LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION Y VAN LTEE.62828 Montreal.Montreal.Montréal.Sainte-Adèle.Pierrefonds.Thetford Mines.Charlesbourg.Joliette.Carleton.St-Denis-de-Brompton.St-Eleuthère.Thetford Mines.Hull.Amos.St-Georges.COMP-TA-BI-LEX INC.103729 COMPTOIR DES INTERMEDIAIRES INC.64668 LES CONFECTIONS LAURENTIENNES INC.63074 CONSTRUCTART INC.116714 .LES CONSTRUCTIONS ROCCO INC.61963 .LA H°YGIENET80CIALf INSPECTEURS' TECHNICIENS EN 118283 Val Mauricie.Baie-de-Vaudreuil.Dollard-des-Ormeaux Montréal.Montréal.Montréal.Saint-Baaile-le-Grand.Montréal.Montréal.19 06 1961 05 04 1961 02 06 1961 04 03 1968 16 11 1961 21 06 1961 22 09 1961 09 03 1962 10 03 1961 27 08 1962 25 09 1966 26 01 1962 25 09 1968 23 06 1961 12 10 1961 09 10 1962 23 06 1961 28 08 1961 10 04 1968 22 12 1961 29 09 1961 09 12 1969 18 08 1961 20 04 1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1971, 106' année, n° U 8225 Nom de la compagnie Name of the company CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS DE WINDSOR.60610 CREATIONS HEDDY LTEE.88289 CREDO INC.63084 R.CYR CONSTRUCTION LTEE.60714 D.C.ELECTRIC INC.112766 DE BLOI8 CONSTRUCTION LTEE.69931 DE VILLERS ET ASSOCIES LTEE.71722 DEBLYN AGENCIES INC.60276 DESMARAIS MANUFACTURING INC.99936 DEVELOPPEMENT PARC SALABERRY INC.61969 DI LILLO & GRASSI LTD.61961 DISTRIBUTION PROVINCIALE INC.76706 DOCHODOVA INVESTMENT CO.LTD.66309 ADRIEN DORE INC.86634 THOMAS A.DUNN LTD.62931 CHARLOTTE ET JEAN DURAND INC.62683 DURAND-MERCIER LIMITEE.61968 GILLES DUVAL INC.82122 E.C.8.PLA8TICS LTD.63673 E.T.REALTIES CO.LTD.64683 EASTERN TOWNSHIP WELDING INC.107647 EASTERN & WESTERN LUMBER COMPANY LIMITED.66313 LES EDITIONS MAURICIENNES INC.63676 ELIDA KNITTING MILL8 LTD.62742 LES ENTREPRISES BOYER, INC.88097 Adresse Incorporation Addreet Date Windsor.20 04 1961 Montreal.21 10 1966 Québec.17 10 1961 Montréal-Nord.19 06 1961 Buckingham.14 07 1969 Trois-Rivières.14 03 1961 Montréal.22 03 1963 Montreal.07 04 1961 Trois-Rivières.15 09 1967 Salaberry-de-Valleyfield.25 08 1961 Montreal.29 06 1961 Montréal.27 01 1964 Montreal.07 02 1962 Cap-Santé.14 07 1965 Chichester.22 09 1961 Montreal.11 08 1961 Loretteville.17 08 1961 Montreal.20 11 1964 Montreal.27 11 1961 Sherbrooke.29 12 1961 Sherbrooke.08 11 1968 Coaticook.08 03 1962 Trois-Rivières.29 11 1961 Montreal.18 08 1961 Québec.14 01 1965 8226 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November ê, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date LES ENTREPRISES C.BIBEAU INC.137851 LES ENTREPRISES LAMCO LTEE.64543 LES ENTREPRISES MONTIER LTEE.61848 LES ENTREPRISES RIVARD INC.61155 LES ENTREPRISES SPERO ANDREWS LTEE.63784 DAVID EPSTEIN INC.64415 F.B.M.RESTAURANT INC.64686 FAIRTON INVESTMENTS LTD.63333 FEDERATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUEBEC INC.114450 Ste-Eustache Lasalle.Québec.Duvernay.South Hull.Montreal .Montreal .Montreal Sainte-Foy.05 07 1972 11 01 1962 10 07 1961 03 05 1961 04 12 1961 15 12 1961 18 01 1962 12 10 1961 26 09 1969 FERBLANTERIE CANADA LTEE 60598 FERME ASSEL1N INC.63115 FIVE BEES INC.63581 THE FORT COULONGE DRIVING CLUB 64140 407 McGILL ST.RESTAURANT INC.61743 JEAN-GUY FOURNEL INC.101033 LES GALERIES DU CAP LTEE 116956 GAZODUCS TRANS-QUEBEC LTEE 63586 GENTY TENNIS CLUB.61412 YVES GERMAIN CONSTRUCTION INC.63337 YVES GERMAIN & FRERES INC.63276 GEROMA CONSTRUCTION LTEE.65118 PHILIPPE GINGRAS LTEE 62839 GOGO CARTAGE & GARAGE CO.63469 GOLD TRADING COMPANY LTD.62606 GOLF MUNICIPAL ANCIENNE LORETTE INC.59943 Lafièche .Montréal.Montreal.Fort-Coulonge.Montreal.Sainte-Foy.Mount Royal.Québec.Gentilly.Québec.Québec.Ste-Anne-des-Monts.Jacques-Cartier.Montreal.Montreal.05 05 1961 .17 10 1961 .25 10 1961 .30 01 1962 .25 07 1961 .14 11 1967 .11 02 1970 .28 11 1961 .10 07 1961 .17 10 1961 17 10 1961 .01 02 1962 .15 09 1961 .11 10 1961 .17 07 1961 \u2022 06 04 1961 Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8227 Nom de la compagnie Name of the company PHILIPPE GOSSELIN (LEVIS) INC.64699 LES GRANDS TRAVAUX DE MONTREAL INC.60867 GRANDMONT BULL DOZER INC.61174 GRANIT GAUTHIER LIMITEE.63949 GRAPH-TECH INC.112925 LA GUILDE DES ARTISTES & TRAVAILLEURS ALLIES INC.62946 HANDYMAN CONSTRUCTION CO.LTD.59632 HARTLAND ACCEPTANCE CORP .61022 HEMAR HOLDINGS INC.63587 HERMES SANDWICH SHOP INC.98849 HI-TEST PREMIER PRODUCTS (CANADA) LTD.59950 HOLIDAY RANCH INC.60736 HOLLINGER ASSOCIATES INC.89701 D.HOMIER INC.60572 HOTEL CHAMPLAIN (LA TUQUE) LIMITEE.61415 HOTEL MONT-SHEFFORD (1970) LIMITEE.121507 HOTEL VICTORIA (LA SARRE) LTEE.60198 LES HOTELIERS DE SHERBROOKE INC.64223 HY ET AL RESTAURANT INC.63285 IBERVILLE MEAT MARKET INC.64918 LES IMMEUBLES DE CHARLEVOIX INC.61860 IMMEUBLE GARAND INC.59715 IMMEUBLES RENSON INC.61023 LES IMPORTATIONS C.B.INC.107519 LES INDUSTRIES LINIERES DU QUEBEC LIMITEE.59379 Adresse Incorporation Address Date Levis.11 12 1961 Montréal.25 05 1961 Danville.22 06 1961 Saint-Marc-des-Carrières 21 11 1961 St-Basile-le-Grand.13 08 1969 Montréal.25 10 1961 Montreal.16 02 1961 Montreal.30 05 1961 Mount Royal.20 11 1961 Montréal.21 06 1967 Montreal .27 03 1961 Montreal.28 04 1961 Montreal.26 01 1966 Montreal.06 06 1961 La Tuque.26 07 1961 Granby.29 10 1970 LaSarre.24 04 1961 Sherbrooke.28 12 1961 Montreal.28 09 1961 Montreal.23 01 1962 Sillery.23 06 1961 Ste-Thérèse.08 03 1961 Hull.07 06 1961 Montréal.31 05 1968 Notre-Dame-des-Prairies 09 02 1961 8228 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 197A, Vol.106, No.Al Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date INDUSTRIES MARCO INC.60443 LES INDUSTRIES VICTOR LTEE.94153 ISOLATION DES CANTONS DE L'EST LTEE.60744 JARDINS DES CEDRES INC.60745 LES JARDINS DU LAC LEBLANC INC.72979 JARRY MOTOR CORPORATION.68870 LA JEUNE CHAMBRE DE MANSEAU INC.105188 LA JEUNE CHAMBRE DE ST-AUGUSTIN INC 109281 KASTEL ENTERPRISES LTD .61628 KELCO LIMITED.59965 ALBERT LABELLE INC.63485 LES LABORATOIRES OMAND LTEE.65290 SERGE LACOURSE INC.97551 LAER INC.140173 LAG INC.65358 LAITERIE CLARK INC.80270 LASALLE MORTGAGE INCORPORATED.59724 LATRE1LLE GAZ NATUREL EQUIPMENT CIE LTEE 52769 PAUL LATREILLE LIMITEE.61868 LAURENTIAN ADJUSTMENT BUREAU LTD.64724 J.O.LEFEBVRE INC.60279 LETOH CORPORATION LTD.62210 LIQUEURS CAZANOVE CORPORATION LTEE 61424 LIQUID CONTROLS CORPORATION (CANADA) LTD 64729 LOISELLE ET CLEMENT INC.139763 .Marieville.Pointe-aux-Trembles____ Sherbrooke.Ste-Thérèse.Montréal.Montreal.Manseau.Saint-Augustin.Montreal.Montreal.Verdun.Montréal.Rosemère.Châteauguay.Ste-Agathe.Terrebonne.Verdun.Montréal.Saint-Jovite.Montreal.Saint-Paul-l'Ermite.St.Laurent.Montréal.Montreal.Salaberry-de-Valleyfield.21 04 1961 12 10 1966 17 04 1961 26 04 1961 07 06 1963 09 10 1962 03 07 1968 11 02 1969 06 06 1961 20 03 1961 26 10 1961 06 02 1962 24 04 1967 25 05 1972 01 03 1962 17 07 1964 14 03 1961 10 11 1959 01 08 1961 18 01 1962 28 04 1961 23 06 1961 17 05 1961 14 12 1961 19 06 1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1971, 106- année, n° U 8229 Nom de la compagnie Same of the company LES LOISIRS DE CONTRECOEUR INC.60756 LES LOISIRS DE L'ESPERANCE INC.59970 LES LOISIRS ST-LUC INC.62004 LES LOISIRS DE SAINT-SAUVEUR DES MONTS INC.64301 LONGUEUIL HOME IMPROVEMENTS LTD.63656 LES LUTINS DU MONT-SUTTON LIMITEE.64302 MT.TREMBLANT HOLDINGS CORP.90961 MAHEUX & GIGUERE INC.63660 MANOIR DES RAPIDES INC.64939 MASS ENTREPRISES LTD.75831 M.MAYER REALTIES INC.87882 MENARD LAUNDROMAT INC.73012 MEUNERIE COWANSVILLE INC.121542 MEUNERIE MOBILE MICHAUD INC.61876 MEUNERIE REGIONALE INC.63171 LA MINE FAUCON LIMITEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 37191 MINIMAX INC.62661 MOBILE FRAME SERVICE CO.LTD.93698 MONARCH PAVING CO.LTD.65161 MONTREAL MILLWORK WINDOW DIVISION LTD.63840 MOON-GLO INC.118480 MOTEL ROUTE NO.2 INC.61222 MOUNTAINLAKE INVESTMENT LIMITED.63603 MUNICIPAL ENTERPRISES LTD.30230 MURALEC INC.135043 Adresse Incorporation Address Date Contrecoeur.01 06 1901 Giffard.23 03 1961 Chicoutimi-Nord.22 08 1961 St-Sauveur-des-Monts .29 12 1961 Côte St-Luc.19 07 1961 Sutton.18 12 1961 Montreal.30 03 1966 St-Philémon.03 11 1961 Limbour.28 02 1962 Montreal.05 12 1963 Montréal.27 09 1966 Ste-Anne-de-Bellevue .11 06 1963 Dunham.17 09 1970 St-Alexandre.07 07 1961 Upton.27 09 1961 Québec.26 07 1966 Montreal.29 08 1961 Laflcche.01 09 1966 Saint-Michel.19 02 1962 Montreal.29 11 1961 Pierrefonds.20 05 1970 Montreal.01 06 1961 Montreal.16 11 1961 Montreal.15 04 1954 Québec.16 02 1972 8230 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 7974, Vol.106, No.U Nom de la compagnie Name al the company N.D.G.FOOTBALL CONFERENCE INC.82359 NORENCY INC.60215 NORTH SHORE FOOTBALL LEAGUE INC.69986 NU COTE INC.123281 OTJ DE LA PAROISSE ST-RAPHAEL DE JONQUIERE INC.60668 L'OEUVRE DES LOISIRS DE ST-GEDEON DE FRONTENAC INC.61777 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE ST-ETIENNE-DES-GRES INC.60217 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DU LAC BOUCHETTE INC.59733 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE VILLE VAL ST-MICHEL.59385 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE LANTIER.63370 PALM INDUSTRIES INC.59746 PAN-AM IRON & METAL CORP.64587 PANTAREI INC.118902 PASMAS INC.109848 PAUL'S PETROLEUM TRANSPORT INC.62022 J.V.PELLETIER LTEE.60458 .PETROLE J.G.COSSETTE INC.95974 .PHARAL PLASTICS INC.61041 .PICKERING MOTORS INC.61042 .LES PLACEMENTS CHOMEDEY LTEE.63191 .LES PLACEMENTS SUDA INC.61640 .PLAGE LEBEL INC.60783 .PLANIPROMOTION INC.143492 .THE PONTIAC LIONS CLUB.60247 .PORTER BROTHERS CONSTRUCTION LTD.61568 .' Adresse Incorporation Address Date Montreal.20 11 1964 Chicoutimi.17 04 1961 Roxboro.07 03 1961 Montréal.18 01 1971 St-Raphaël-de-Jonquière 28 04 1961 Saint-Gédéon.02 08 1961 St-Etienne-des-Grès.29 03 1961 Lac Bouchette.17 03 1961 Val-St-Michel.01 03 1961 Lantier.18 12 1961 Montreal.17 02 1961 Montreal.20 12 1961 Québec.22 06 1970 Montreal.04 03 1969 Greenfield Park.09 08 1961 Val d'Or.27 04 1961 Cap-de-la-Madeleine.,.30 01 1967 St-Lambert.23 05 1961 Montreal.08 06 1961 Montréal.31 10 1961 Longueuil.04 08 1961 Repentigny.24 05 1961 St-Léonard.19 03 1973 Village of Campbell's 10 06 1961 Bay.St.Andrews East.17 07 1961 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 novembre 1971, 106' année, n° U 8231 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date PRIME WINDOWS OF CANADA (QUEBEC) LIMITED____ 59572 PROPERTY OWNERS ASSOCIATION OF THE TOWN OF ST.EUSTACHE SUR LE LAC 60114 PROVINCIAL FRUIT CO.OF ROUYN QUE.LIMITED.63866 PYEQUART LTD.60017 Montreal.03 02 1961 St.Eustache-sur-le-Lac .29 03 1961 QUEBEC AUTO IGNITION INC.63749 QUEBEC GENERIC DRUG PRODUCTS INC.62677 QUEBEC HOIST TRUCK INC.56220 QUEBEC STEEL SETTING INC.39916 J.T.QUENNEVILLE INC.60793 RAPID PLASTICS LTD.69856 RAYMOND MOTORS LTD.87481 REALTONE ELECTRONICS LIMITED 64597 REMER FUR CO.INC.61052 RENOVATION CARTIER INC.62976 RICHELIEU ACRES LTD.62116 ROBAT DEVELOPMENT INC.61264 B.N.ROBINSON & CIE LTEE 66187 ROGERS HOUSEWARES LIMITED.61672 RONA DEVELOPMENT INC.61618 ROSEMERE INVESTMENTS INC.63516 L.G.ROY INC.64248 ST-BRUNO HORSE SHOW INC.61373 ST-LAMBERT RIFLE CLUB INC.73065 ST-LAWRENCE BOWMEN INC.61486 SABLEC INC.81092 Rouyn.Mount Royal.Montreal.Cap-Rouge.Quebec.Québec.Salaberry-de-Valleyfield.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Granby.Montreal.Montreal.Rosemère .Québec.St-Bruno.St-Lambert.Montreal.Sorel.12 10 1961 23 03 1961 06 12 1961 26 09 1961 18 07 1960 04 04 1957 03 05 1961 11 12 1962 26 08 1965 05 01 1962 02 06 1961 06 09 1961 26 09 1959 16 06 1961 02 02 1962 18 07 1961 10 07 1961 28 11 1961 13 12 1961 26 05 1961 29 05 1963 28 06 1961 10 09 1964 8232 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1971, Vol.106, No.U__ Nom de la compagnie Name of the company SABRE SERVICE STATION LTD.59637 SAGUENAY CONSTRUCTION (1961) INC.61061 SALAISON DES BOIS-FRANCS INC.64478 SALAISON VILLE EMARD INC.63265 SALLE D'ACCUEIL DOMREMY-GRAND'MERE.64331 SALON DES ARTS DE SHAWINIGAN.63242 LES SALONS BEDARD INC.62686 LE SALON DE SANTE DE QUEBEC INC.48542 PAUL SAMSON LTEE.62795 SANIPHANE CO.LTD.61073 SANI-THERMO INC.36660 SCHMOE REALTIES LTD.63878 MORRIS SCHWARTZ HOLDINGS INC.63702 SCOTCHER ENTERPRISES INC.83515 LES SCOUTS DE ROBERVAL INC.64482 SCRAD INC.127277 SEPT ILES STEAK HOUSE INC.62050 SERBA INC.107940 SERVICE D'HABITATION GHYLOR LIMITEE.63995 SERVICE DES LOISIRS ST-CHRI8TOPHE DE PONT-VIAU.59589 SERVICE DES LOISIRS STE-GERMAINE-COUSIN.62063 \" ' SHARON'S RESTAURANT INC.62381 .SHA WBRIDGE BAKERY LTD.64111 .SIROIS CONSTRUCTION INC.129030 .SIXTY-EIGHT DEVELOPMENT INC.52399 .Adresse Incorporation Address Date Montreal.16 02 1961 Montreal.01 06 1961 Sainte-Clothilde.12 12 1961 Montreal.02 11 1961 Grand'Mère.29 12 1961 8hawinigan.29 12 1961 Cowansville.25 08 1961 Québec.03 04 1969 Thetford Mines.26 08 1961 Montreal.19 06 1961 Québec.03 05 1966 Montreal.07 12 1961 Montreal.12 10 1961 Montreal.13 01 1965 Robe rv al.07 12 1961 Montreal.08 04 1971 Sept-Iles.21 07 1961 Hull.25 11 1968 Sherbrooke.04 12 1961 Pont-Viau.06 03 1961 Pointe-aux-Trembles .21 08 1961 Montreal.27 07 1961 Shawbridge.01 10 1961 Chandler.18 06 1971 Montreal.07 08 1969 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 197A, 106' année, no U 8233 Adresse Incorporation Address Date Montreal.11 08 1937 Montréal.12 12 1961 Montréal.12 09 1961 Cowansville.12 10 1961 Ville Jacques-Cartier .21 11 1964 Trois-Pistoles.17 11 1966 Montréal.20 10 1964 Sherbrooke.18 12 1961 Montreal.15 10 1957 Thetford Mines.04 07 1972 Gatineau.17 03 1972 Québec.16 04 1957 Montreal.08 03 1967 Alma.16 02 1965 Hull.12 01 1973 Montreal.02 11 1962 Alma.16 04 1963 La Guadeloupe.24 09 1971 Beaconsfield.16 06 1966 Montreal.08 01 1962 Montreal.10 12 1970 Chambly.14 04 1971 Montreal.21 08 1961 Montréal.10 04 1970 Montréal.09 11 1961 Nom de la compagnie Name of the company SLÀDEN (QUEBEC) LIMITED.7651 LA SOCIETE MARQUETTE INC.64116 LA SOCIETE PAUL DUBORD LIMITEE.63993 SOUDO-MEG INC.63707 SOUTH SHORE MARINE & INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.82307 SPECIALITES DIONNE LTEE.94821 J.S.STAEDILER QUEBEC LTEE.81644 FABIEN STONE CORPORATION LTD.65017 STRUCTURAL ERECTORS LTD.41555 STUDIO D'AMAIGRISSEMENT FORME MIRACLE DE THETFORD MINES INC.138063 TABAGIE LOUFAR LTEE.135429 LE TANGON INC.39836 TERRASSE THERESE INC.96544 LE THEATRE DE LAIRELINC.83815 DOROTHY THOMSON INC.142652 TITANIC DEVELOPMENT LIMITED.69349 TREMBLAY & TREMBLAY PLATRIERS LTEE.72188 TREPERO INC.130679 TRI-TAB OF CANADA LTD.93561 TRUE-TORQUE BRAKE COMPANY.66023 UP RITE DEVELOPMENT CORP.OF MONTREAL INC.123967 LES USINAGES DE CARIGNAN INC.128465 VAL ROY MOTORS INC.62126 LES VALEURS CONCORDE LTEE.118396 VARIETES MOZART INC.63826 8234 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1971, Vol.106, No.11 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Incorporation Date VIAU ASPHALT & PAVING INC.35624 WHITE CROSS UNIFORM LIMITED.64132 Salaberry-de-Valleyfield.22 02 1956 Montreal.29 09 1961 58868-0\tLe directeur du service des compagnies, Pierre Desjardinb\t58868-0\tPierre Desjardinb, Director of the Companies Service.\tAssurances\t\tInsurance CATHOLIC ORDER OF FORESTERS Avis d'annulation de permis et de certificat d'enregistrement Attendu que « CATHOLIC ORDER OF FORESTERS », une société de secours mutuels, dont le siège social est situé à Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, a cessé de faire affaires au Québec le 30 juin 1974 ; Attendu que la société « CATHOLIC ORDER OF FORESTERS » a produit au Service des assurances un exemplaire de l'accord en vertu duquel « LES ARTISANS, SOCIETE COOPERATIVE D'ASSURANCE-VIE » ont acheté et pris à charge les opérations et les biens au Canada et au Québec de la « CATHOLIC ORDER OF FORESTERS ».En conséquence, avis est par les présentes donné que le permis et certificat d'enregistrement de « CATHO-I.rC ORDER OF FORESTERS » sont annulés à compter du 1er juillet 1974.Donné au bureau du Service des assurances, Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives, le 18 octobre 1974.Pour le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province, L'Inspecteur des sociétés de secours mutuels, 58858-43-2-0 Rogfr-A.Camahaihh.MIDDLESEX MUTUAL INSURANCE COMPANY Avis de changement de raison sociale Avis est donné par les présentes que « MIDDLESEX MUTUAL INSURANCE COMPANY », constituée en corporation sous l'empire des lois du Massachusetts, États-L\" nis d'Amérique, et enregistrée au Service des assurances du Québec sous le numéro 717, a changé son nom en celui de « MIDDLESEX INSURANCE COMPANY » et est devenue une compagnie à fonds social.Fait à Boston, Massachusetts, États-Unis d'Amérique, le 16 août 1974.Le secrétaire, 58813-43-2-0 Andrew M.Innés.CATHOLIC ORDER OF FORESTERS Notice of Cancellation of License and Certificate of Begistration Whereas \"CATHOLIC ORDER OF FORESTERS\", being a mutual benefit association, whose lead office is situated at Chicago, Illinois, United States of America, has ceased to do business in Québec on the 30th of June, 1974; Whereas \"CATHOLIC ORDER OF FORESTERS\" society has filed with the Insurance Branch a copy of the agreement under which \"THE ARTISANS, LIFE INSURANCE COOPERATIVE SOCIETY\" have purchased and taken over the business and property in Canada and in Québec of \"CATHOLIC ORDER OF FORESTERS\".Therefore, notice is hereby given lhat the license and certificate of registration of \"CATHOLIC ORDER OF FORESTERS\" are cancelled as from the 1st of July, 1974.Given at the office of the Insurance Branch, Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the 18th of October, 1974.For the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province, Rooer-A.Camaraire, 58858-43-2-0 Inspector of Mutual Benefit Associations.MIDDLESEX MUTUAL INSURANCE COMPANY Notice of change of name Notice is hereby given that \"MIDDLESEX MUTUAL INSURANCE COMPANY\", incorporated under the laws of Massachusetts, United States of America, and registered with the Québec Insurance Branch under number 717, has changed its name to: \"MIDDLESEX INSURANCE COMPANY\" and has been transformed into a stock company.Dated at Boston, Massachusetts, United States of America, this 16th of August, 1974.Andrew M.Innes, 58813-43-2-0 Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1971, 106- année, no 11 8235 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission (Règlement 2, a.2.24) : « proprio motu > 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.Fil \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).IV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées, i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II -Notice of submission of application (Regulation 2, s.2.3) : i \u2014 3.\u2014 4.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Applications for verification of permits (s.2.59).Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedngs.\u2014 General tranS|Xirt of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). 8236 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(c) Verification of permits.(d) Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.(e) * Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur M I'Y QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve M auve Brun Brown M 000001 Q (1110(11)1 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M ;,oooo! Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 à Q 001000 à M 103000 àQ 102000 à M 210000 à Q 205000 à M 303000 àQ 302000 à M 402000 àQ 401000 à M 504000 àQ 503000 à M 601000 àQ 600500 à M 700500 àQ 700500 à M 800500 àQ 800500 à M 900500 àQ 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab JJCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971, 106' année, n° U 8237 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport specialise \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail II \u2014 Avis d'introduction de requêtes : La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications : The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle Q-1953 Q-501919 D-001 real plourde 11, De La Baie Port-Cartier Comté Saguenay (Que.) Rôle Q-1981 Q-502994 D-001 laval gaudreault 2019, rue des Mélèzes Dolbeau Comté Roberval (Que.) Rôle Q-2189 22811-V-D-2 boucher, charles a.275, Malouin, Matane Comté Matane (Que.) Tireur / Haulaway operator et/and 6793-V brazeau transport inc.380, rue Burke Rouyn Comté Témiscamingue (Que.) Tiré / Carrier Requérants conjoints Joint applicants Rôle Q-2190 Q-200775 marcoux, maurice 1266, St-Cyrille Ouest Québec 6 (Que.) et / and Q-202095 nadeau, jean 294, Marie-Louise Québec (Que.) Le requérant qui possède une attestation Q-501919 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 9.N.B.Nouvelle publication remplaçant celle du 5 octobre 74 qui était erronée.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Artisan, dans la région No 2.N.B.Nouvelle publication remplaçant celle du 5 octobre 74 qui était erronée.Service additionnel: Transport par remorquage - contrat -Demande est faite d'autoriser Charles A.Boucher a tirer avec ses tracteurs dûment enregistrés les remorques de Brazeau Transport Inc., (6793-V).selon les clauses c à /// inclusivement dudit permis No 6793-V.Demande de transfert : Marcoux, Maurice demande à la Commission de transférer à: Nadeau, Jean 294, Marie-Louise Québec (Que.) le permis No Q-200775 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Québec, A-36.The applicant, who holds certificate Q-501919, D-001.requests a bulk trucking permit for region No.9.Contractor class.Note: New publication replacing that dated October 5, 1974, which was erroneous.The applicant requests a bulk trucking permit for region No.2.Artisan class.Note: New publication replacing that dated October 5, 1974, which was erroneous.Additional service.Haxilaway transport - contract -Request is made to authorize Charles A.Boucher to haul, with his duly-registered tractors, the trailers of Brazeau Transport Inc., (6793-V) according to clauses c to fff inclusive of said permit.Application for transfer: Marcoux, Maurice requests the Commission to transfer to: Nadeau, Jean 294 Marie-Louise Québec, P.Q.permit No.Q-200775, to effect transport by taxicab in conglomeration A-36, Québec. 8238 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November ft 1974, Vol.106, No.U Rôle Q-2191 Q-201463 D-l BLIER, JACQUES 86, Bellevue Rivière-du-Loup et/and Q-202091 BOURGELAS.JACQUES 53, côte St-Jacques Ri vie re-du-Loup Demande de transfert: lîlier, Jacques demande à la Commission de transférer à: Bourçelas, Jacques 53, côte St-Jacques Rivière-du-Loup le permis No Q-201463 D-l pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Rivière-du-Loup, A-13.Application for transfer: Blier, Jacques requests the Commission to transfer to: Bourgelas.Jacques 63 Côte St-Jacques Rivière-du-Loup permît No.Q-201463 D-l, to effect transport by taxicah in conglomeration A-13, Rivière-du-Loup.Rôle Q-2192 6311-V-D-3 V.BOUTIN EXPRESS INC.CP.400, 1397, rue Savoie Plessisville, Comté Mégantic G6L 1J8 Rôle Q-2193 5686-V-D-l 5686-V NICOLE, ALFRED 70, avenue des Erables Montmagny (Que.) et/and 3312-V-D-2 3312-V CARON & FILS TRANSPORT INC.Chemin des Poiriers Montmagny (Que.) Modification de la clause c : La partie requérante détient un permis dont la clause c se lit comme suit: Transport général - longue distance - route restreinte - De Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Lvster, Lauricrville, St-Pierre-Baptiste, Ste-Sophie, St-Ferdinand, Princeville, Dosquet.St-Agapit et Ste-Agathe-de-Lotbinière à Montréal, via routes 5, 20 et 9 à Trois-Rivières, via routes Nos 5 et 34, à Sherbrooke, via route No 5 et les points intermédiaires et retour.Considérant que In ponctuation telle qu'inscrite dans la rédaction de la clause ci-dessus mentionnée est ambiguë, la requérante, tout en demandant la correction, désire que la susdite clause c se lise a l'avenir comme suit: Transport général - longue distance - route restreinte - De Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre-Baptiste.Ste-Sophie, St-Ferdinand, Princeville.Dosquet, St-Agapit et Ste-Agathe-de-Lotbinière à Montréal via routes 5, 20 et 9.à Trois-Rivières via routes 6 et 34, à Sherbrooke via routes 1, 5 et 49, et les points intermédiaires et retour.Demande de transfert: Alfred Nicole demande que son permis de transport No 56S6-V soit transféré à la compagnie Caron & Fils Transport Inc.(3312-V).Le permis de transport No 5686-V: Transport général - Montmagny et environs.Transport général - Occasionnellement de Montmagny à Québec et retour, pour le transport de marchandises destinées à Montmagny ou en provenant.Modification of clause c: The applicant holds a permit in which clause c reads as follows: General trucking - long distance - restricted route - From Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre^ Baptiste, Ste-Sophie.St-Ferdinand, Princeville, Dosquet, St-Agapit and Ste-Agathe-de-Lotbinière to Montreal, via Highways 5, 20 and 9 to Trois-Rivières, via Highways Nos.5 and 34, to Sherbrooke, via Highway No.5 and intermediate points and return.Whereas the punctuation, as it exists in the wording of the above-mentioned clause, is ambiguous, the applicant, while requesting the correction of said clause, wishes the aforesaid clause c to read henceforth as follows: General trucking - long distance - restricted route - From Plessisville, Notre-Dame-de-Lourdes, Lyster, Laurierville, St-Pierre-Baptiste, Ste-Sophie, St-Ferdinand, Princeville.Dosquet, St-Agapit and Ste-Agathe-de-I*ot-binière to Montreal via Highways 5, 20 and 9, to Trois-Rivières via Highways 5 and 34, to Sherbrooke via Highways 1, 5 and 49, and intermediate points and return.Application for transfer: Mr.Alfred Nicole requests that his transport permit No.G6S6-V be transferred to Caron & Fils Transport Inc.(3312-V).Transport permit No.5686-V: General trucking - Montmagny and vicinity.General trucking - Occasionally from Montmagny to Québec City and return, for the transport of goods shipped to or originated from Montmagny.Rôle Q-2194 22719-V-D-l CAPITAINE HORACE JOMPHE Havre-St-Pierre (Que.) et/and JOMPHE EXPRESS ENRG.(Capt.Horace Jomphe et / and André H.Jomphe) Havre-St-Pierre (Que.) Demande de transfert: Capitaine Horace Jomphe demande que son permis de transport No 22719-V soit transféré à: Jomphe Express Knrg.(Capt.Horace Jomphe et André H.Jomphe) Havre-St-Pierre Cté Saguenay lequel se lit comme suit : a) Transport général - service local - a) Havre-St-Pierre et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limite?de ladite localité.b) Transport général - longue distance -route restreinte - 6) De Havre-St-Pierre, a Longue-Pointe-de-Mingan, Rivière-St-Jean, Magpie, Ri-vière-au-Tonnerre et Sheldrake, et retour.Application for transfer: Captain Horace Jomphe requests that his transport permit No.22719-V be transferred to: Jomphe Express Enrg.(Capt.Horace Jomphe and André H.Jomphe) Havre-St-Pierre, County of Saguenay said permit reads as follows: (a) General trucking - local service - ( : I \u2014 Notice \" proprio motu \" by the Commission La Commission donne avis qu'elle entend décider de l'affaire suivante conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement no 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.The Commission gives notice of its intention to settle the following proceeding in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation No.2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Rôle M-3770 MT-7493 Michaud, Gilles 12365, rue Matte, app.3 Montréal-Nord.Que.55870-O Aux fins de réviser ou de révoquer pour cause, s'il y a lieu, la décision rendue le 2 octobre 1974 sous le numéro MPT77993 autorisant la délivrance d'un permis de transport par véhicu'.c-taxi de _ catégorie « Agglomération » et de catégorie « Ordinaire » pour l'agglomération A\u20145 est de Montréal.S'il y a opposition ou intervention ou demande dans les dix jours de la publication de cet avis, l'audience publique à être tenue en conséquence aura lieu à Montréal, le lundi 18 novembre 1974.en la division No 2, à lOh du matin.For the purpose of revising or cancelling, if need be, the decision rendered on October 2, 1974 No.MTP-7993 authorising the delivery of a permit to effect transport by taxicab \"conglomeration\" class and \"regular\" class in conglomeration A-5 East of Montreal.If within ten (10) days after the publication of this notice, an objection or intervention or requests, is filed, the public hearing to be held will be at Montreal on Monday, November 18, 1974, Division No.2, at 10:00 o'clock in the morning.V \u2014 Avis de decisions rendues : La Commission donne avis de la nature des décisions sui vantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered : The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.DECISIONS DE LA COMMISSION ¦ PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION No\tDate\tRequérants Applicants\tG page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions QCR-805 La Commis, permis et anri 19350-V.QCR-816\t15-10-74 ion révoqu ule à toute 17-10-74\t19350-V-P-l LEO MURDOCH ; la ou les décisions autorisant tel Th s fins que de droits ledit permis such purp 7737-V-P-l BELLECHASSE TRANSPORT INC.\t6874 e Com permit oses.3333\t21-09-74 nission rev and cancel 04-05-74\tQ-1849 akes the or s said périr Q-1038\tdecision (s) authorizing it 19350-V, for all legal La Commission: 1.maintient la décision fondamentale rendue le 13 août 1973 par la Commission dans la cause 2232; 2.revise la susdite décision en ce qui concerne la rédaction des permis de l'intimée, connus comme les clauses d et e pour qu'ils se lisent désormais comme suit : d) Transport général - longue distance - route restreinte -De Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge et Donnacona à Montréal, et retour.e) Transport général - longue distance - route restreinte -De Cap-Santé, St-Basile.Pont-Rouge et Donnacona à Québec, et retour.The Commission: 1.maintains the substance of the decision rendered by the Commission on August 13, 1973, regarding case 2232; 2.revises the abovementioned decision concerning the Wording of the defendant's permits, known as clauses d and e, to read henceforth as follows: (d) General trucking - long distance - restricted route -From Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge and Donnacona to Montreal, and return.(e) General trucking - long distance - restricted route -From Cap-Santé, St-Basile, Pont-Rouge and Donnacona, and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 7974, 106' année, n\" U 8277 \t\tRequérants No\tDate\tApplicants QCS-414\t15-10-74\t7041-V-P-2 \t\tTRANSPORT AMEDEE CAYER INC.Voiturier-roulier / Carrier 19350-V LEO MURDOCH 23264-V GILLES BOULAY 23183-V YVON GREGOIRE 22782-V ROBERT BELANGER Voituriers-remorqueurs Haulaway operators G.O.Q.\t\t\t \t\tCause\t page\tdate\t\tDécisions \t\tCase\t 6874\t21-09-74\tQ-1850\t La Commission révoque à toutes fins que de droit la ou les décisions autorisant la délivrance du permis du tiré, Transport Amédée Cayer Inc., No 7041-V, connexe aux permis des tireurs ci-après nommés, et vice-versa : 19350-V 23264-V 23183-V 22782-V QCS-115 Léo Murdock Gilles Boulay Yvon Grégoire Robert Bélanger 15-10-74 The Commission revokes, for all legal purposes, the deci-sion(s) authorizing the issue of the permit of the carrier, Transport Amédée Cayer Inc., No.7041rV, related to the permits of the haulaway operators hereinafter mentioned, and vice versa: 19350-V Léo Murdock 23264-V Gilles Boulay 23183-V Yvon Grégoire 22782-V Robert Bélanger 11437-V-P-2 L'ISLET EXPRESS INC.Voiturier-roulier / Carrier 23520-V PIERRE LEVESQUE 21854-V PAUL-EMILE ROBICHAUD 23210-V BRUNO LORD Voituriers-remorqueurs Haulaway operators La Commission : 1.révoque les décisions autorisant l'émission des permis: 23210-V Bruno Lord 23520-V Pierre Lévesque 21854-V Paul-Emile Robichaud.voituriers-remorqueurs t 11437-V LTslet Express Inc., mise en cause.2.autorise l'émission des permis suivants : 23520-V Pierre Lcvesque 21854-V Paul-Emile Robichaud 23210-V Bruno Lord, voituriers-remorqueurs 7021 28-09-74 Q-1873 The Commission: 1.revokes the decisions authorizing the issue of permits: 23210-V Bruno Lord Pierre Lévesque Paul-Emile Robichaud, haulaway operators 23520-V 21854-V and 11437-V L'Islet Express Inc., mise encause.2.authorizes the issue of the following permits: 23520-V Pierre Levesque Paul-Emile Robichaud Bruno Lord, haulaway operators ct 11437-V LTslet Express Inc., voiturier-roulier.21854-V 23210-V and 11437-V LTslet Express Inc.carrier.QSM-46 15-10-74 12-N-P-l RAPID STEAMSHIP COMPANY 7021 28-09-74 Q-1973 La Commission révoque la décision autorisant l'émission du permis 12-N et annule ledit permis à toutes fins que de droit.The Commission revokes the decision authorizing the issue of permit 12-N and cancels said permit for all legal purposes QSM-17 15-10-74 127-N-P-l ST-SIMEON NAVIGATION INC.7021 28-09-74 Q-1972 La Commission, à la demande de la détentrice, révoque la décision autorisant le permis No 127-N et annule ledit permis à toutes que de droit.The Commission, to the holder's request, revokes the decision authorizing permit No.127-N and cancels said permit for all legal purposes.QS-626 09-10-74 2-502841 3ASTON CLOUTIER La Commission : 1.revise la décision QS-466 concernant la confiscation du montant de $50 fait par l'Association Nationale des Camionneurs Artisans Indépendants Inc.; 2.statue à nouveau sur ledit montant pour décréter la remise du montant de $50 fait par l'Association Nationale des Camionneurs Artisans Indépendants Inc.5816 17-08-74 Q-1589 The Commission: 1.revises decision QS-466 concerning the seizure of the $50 deposit made by the Association Nationale des Camionneurs Artisans Indépendants Inc.; 2.gives a further decision on the said amount to order the reimbursement of the $50 deposit made by the Association.Nationale des Camionneurs Artisans Indépendants Inc. 8278 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 No Date Requérants Applicants QS-627 09-10-74 Q-501117 ALLEN DUMARESQ La Commission: 1.revise la décision QS-480 concernant la confiscation du montant de $50 fait par l'Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.; 2.statue à nouveau sur ledit montant pour décréter la remise du montant de $50 fait par l'Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.G.O.Q.page date 5817 17-08-74 Cause Case Q-1590 Décisions The Commission: 1.revises decision QS-480 concerning the seizure of the $50 deposit made by the Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.; 2.gives a further decision on the said amount to order the reimbursement of the $50 deposit made by the Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS QCR-814\t10-10-74\t23673-V-D-l GEORGES CHRETIEN Nouvelle demande / New application\t3002\t20-04-74\tQ-1000\tRejetée/ Rejected QCR-815\t17-10-74\t5045-V-D-l TRANSPORT THIBAULT INC.Service additionnel / Additional service\t3336\t04-05-74\tQ-1021\tAccordée telle qu'amendée Granted as amended QCR-817\t17-10-74\t32-V-D-5 TRANSPORT DALLAIRE LIMITEE Service additionnel/ Additional service\t3346\t04-05-74\tQ-1032\tAccordée / Granted QCR-818\t17-10-74\t23671-V-D-l JEAN-MARC LACOURSE Nouvelle demande / New application\t3467\t11-05-74\tQ-1098\tAccordée / Granted QCR-819\t17-10-74\t4373-V-D-3 MICHEL TRANSPORT INC.\t6483\t14-09-74\tQ-1794\t La Commission prend acte du retrait de la demande par la requérante.QPV-370 10-10-74 The Commission records the applicant's withdrawal of his request.3563-A-D-l MICHEL ROBICHAUD La Commission prend acte du retrait de la demande.3336 04-05-74 Q-1022 QCS-413 MCS-758 11-10-74 10-10-74 The Commission records the withdrawal of the request.23716-V-D-l TRANSPORT SAMSON INC.Nouvelle demande / New application 23467-V-D-4 GERARD ROY 8123-V-D-6 JOHN N.BROCKLESBY TRANSPORT LTD.La Commission annule le permis spécial MS-346 émis le 28 novembre 1973.2806 3859 13-04-74 25-05-74 Q-0978 M-1964 Accordée / Granted Désistement IKtMdrauial MCS-760 11-10-74 The Commission cancels special permit No.MS-346 issued on November 28, 1973.298-V-D-l BORISKO BROS.(QUEBEC) LTD.La Commission annule à toutes fins que de droit l'autorisation accordée à Borisko Bros.(Québec) Ltd.d'exploiter le service de ferroutage (piggy back) autorisé parla clause c-1 de son permis.4802 29-07-74 M-2353 The Commission cancels, for all legal purposes, the authorization granted to Borisko Bros.(Québec) Ltd.to operate the piggyback service authorized by clause c-1 of its permit.MCS-761 MCS-762 11-10-74 11-10-74 4-V-D-2 INTER CITE TRANSPORT LIMITEE 12762-VM M.J.CAMPBELL LIMITED Requéran te- venderesse A pplicant-vendor M.J.CAMPBELL INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser (Bulletin: 1-1-99) 4995 2555 13-07-74 28-04-73 M-2399 Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° U 8279 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tpage\tdate\t\tDécisions \t\t\t\t\tCase\t MCS-763\t15-10-74\t40003-D-58-TF\t5158\t20-07-74\tM-2507\tAccordée / Granted \t\tCANADIAN HOUSEHALD GOODS\t\t\t\t \t\tCARRIERS TARIFF BUREAU\t\t\t\t \t\tASS'N\t\t\t\t QPV-374\t23-10-74\t2750-A-D-l\t915\t26-01-74\tQ-576\tAccordée / Granted \t\tTRANSPORT SCOLAIRE DE\t\t\t\t \t\tCHAUVEAU LTEE\t\t\t\t QCIt-830\t23-10-74\t9570-V-D-l\t4919\t25-08-73\tQ-74\tRejetée / Rejected \t\tCOUTU TRANSPORT EXPRESS\t\t\t\t \t\tLIMITEE\t\t\t\t MCR-1266\t22-10-74\t9570-V & 9570-V-D-Y\t2233\t14-04-73\tQ-651\tDésistement MCS-78S\t\tLAMOTHE TRANSPORT INC.\t\t\tM-3373\tWithdrawal \t\t\t2239\t14-04-73\tQ-652\tRejetée / Rejected \t\t\t\t\tM-3638\t \t\t\t5032\t13-07-74\tQ-1423\tRejetée / Rejected SEANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS QCV-79 16-10-74 Q-501333 MARTIN LEBLANC Requérant-cédant A pplicant-transf error RAYMOND AUDET Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Martin Leblanc en vertu de son attestation Q-501333: 2.révoque n toutes fins que de droit l'attestation Q-501333; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Raymond Audet, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-80 16-10-74 Q-502233-D-2 LUCIEN BRIERE Requérant-cédant A pplicant-transf error ROBERT L.BRIERE Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Lucien Brière en vertu de son attestation Q-502233-D-2; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502233-D-2; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Robert L.Brière.la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-81 16-10-74 Q-502233-D-1 LUCIEN BRIERE Requérant-cédant Applicant-transferror RAYMOND L.BRIERE Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Lucien Brière en vertu de son attestation Q-502233-D-l; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502233-D-l; 6120 31-08-74 Q-1631 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Martin Leblanc by virtue of his certificate Q-501333; 2.revokes certificate Q-501333 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Raymond Audet, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6122 31-08-74 Q-1637 The Commission : 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Lucien Brière by virtue of his certificate Q-502233-D-2; 2.revokes certificate Q-502233-D-2 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee.Robert L.Brière, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6122 31-08-74 Q-1638 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Lucien Brière by virtue of his certificate Q-502233-D-1; 2.revokes certificate Q-502233-D-1 for all legal purposes; S280 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\tCase\t 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Raymond L.Brière, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-82 16-10-74 Q-502254 IRENEE LECLERC Requérant-cédant Applicant-transf error GUY LECLERC Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree La Commission: 1.Autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Irenée Leclerc en vertu de son attestation Q-502254; 2.Révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502254; 3.Autorise en faveur du_ requérant-cessionnaire, Guy Leclerc, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-83 16-10-74 Q-501677-D-2 EDGAR LAMOTHE Requérant-cédant A pplicant-transf error JEAN GUY BOUDREAULT Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.Autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Edgar Lamothe en vertu de son attestation Q-501677-D-2; 2.Révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-5C1677-D-2; 3.Autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Jean-Guy Boudreault, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-84 16-10-74 Q-503536 GEORGES EMILE LAVOIE Requérant-cédant A pplicant-transf error ODINA VALLEE Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Georges Emile Lavoie en vertu de son attestation Q-503536; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-503536; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire.Odina Vallée, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-85 16-10-74 Q-501642 RAYMOND ST-HILAIRE Requérant-cédant Applicantrtransferror GUY TANGUAY Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage er.vrac donné par Raymond St-Hilaire en venu de son attestation Q-501642; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Raymond L.Brière.upon payment of the required charges; such certificate shall not he considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6120 31-08-74 Q-1628 The Commission: 1.Authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided bv Irenée Leclerc by virtue of his certificate Q-502254; 2.Revokes certificate Q-502254 for all legal purposes; 3.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Guy Leclerc, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6123 31-08-74 Q-1641 The Commission: 1.Authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Edgar Lamothe by virtue of his certificate Q-501577-D-2; 2.Revokes certificate Q-501677-D-2 for all legal purposes; 3.Authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Jean-Guy Boudreault, upon payment ot the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6122 31-08-74 Q-1640 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service r.r°srlo«cby Geor8es Emile Lavoie by virtue of his certificate W~503536; 2.revokes certificate Q-503536 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Odina Vallée, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6120 31-08-74 Q-1629 The Commission: nrn1; i^dhkrizr the diMontinuance of the bulk trucking service Q-60?M2^y Raymond St-Hilaire by virtue of his certificate GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, s novembre 1974, 106' année, n° U 8281 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-501642; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Guy Tan-guay, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-86 16-10-74 Q-500379 O'BRIEN LESAGE Requérant-cédant A pplicant-transf error MARCEL BERGERON Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par O'Brien Lesage en vertu de son attestation Q-500379; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-500379; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Marcel Bergeron, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.2.revokes certificate Q-501642, for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferree.Guy Tanguay, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6120 31-08-74 Q-1630 The Commission : 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by O'Brien Lesage by virtue of his certificate Q-500379; 2.revokes certificate Q-500379 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Marcel Bergeron, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QCV-87 16-10-74 Q-600327-D-2 ALINE B.CLAVEAU Requérante-cédante Applicant-transf error L.CLAVEAU TRANSPORT ENRG.Requérant-cessionnaire A pplicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Aline B.Claveau en vertu de son attestation Q-500327-D-2; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-500327-D-2; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, L.Claveau Transport Enrg., la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.6126 31-08-74 Q-1674 The Commission : 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Aline B.Claveau by virtue of his certificate Q-500327-D-2; 2.revokes certificate Q-500327-D-2 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, L.Claveau Transport Enrg., upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QCV-88 16-10-74 Q-500327-D-3 ALINE B.CLAVEAU Requérante-cédante Applicant-transf error L.CLAVEAU TRANSPORT ENRG.Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Aline B.Claveau en vertu de son attestation Q-500327-D-3; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-500327-D-3 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, L.Claveau Transport Enrg., la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.6126 31-08-74 Q-1676 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Aline B.Claveau by virtue of his certificate Q-500327-D-3; 2.revokes certificate Q-5O0327-D-3 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, L.Claveau Transport Enrg., upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QCV-89 16-10-74 Q-503267 LEONARD POULIN Requérant-cédant Applicant-transf error GILDOR LEBLANC Requérant-cessionnaire Applicant-transferee 6127 31-08-74 Q-1696 S2S2 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106.No.44 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\tDécisions No\tDate\t\tpage\tdate\t\t \t\tApplicants\t\t\tCase\t La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Léonard Poulin en vertu de son attestation Q-503267; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-503267; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Gildor Leblanc, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-90 16-10-74 Q-502246 PAUL EMILE LA VOIE Requérant-cédant Apvliea nt-tra ne f error JEAN MARIE BOUCHARD Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Paul Emile Lavoie en vertu de son attestation Q-502246; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502246; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Jean Marie Bouchara, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permil.QCV-91 16-10-74 Q-502512-D-2 EDMOND A.CYR Requérant-cédant A pplicant-tranaferror REMI A.ARSENAULT Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Requérant-cessionnaire La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Edmond A.Cyr en vertu de son attestation Q-502512-D-2; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-502512-D-2; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Rémi A.Arsenault, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV «J2 16-10-74 Q-500830 NORMAND ROYER Requérant-cédant A pplicant-transf error PAUL AIME DUMAS Requérant-cessionnaire Applicant-transferee La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Normand Royer en vertu de son attestation Q-500830: 2.révoque a.toutes fins que de droit l'attestation Q-500830; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Paul-Aimé Dumas, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Léonard Poulin by virtue of his certificate Q-503267; 2.revokes certificate Q-503267 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Gildor Leblanc, upon payment of the required charges: such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6126 31-08-74 Q-1679 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Paul Emile Lavoie by virtue of his certificate Q-502246; 2.revokes for all legal purposes certificate Q-502246 for al' legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee.Jean Marie Bouchard, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6121 31-08-74 Q-1678 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Edmond A.Cvr by virtue of his certificate Q-502512-D-2; 2.revokes certificate Q-502512-D-2 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behnlf of the applicant-transferee, Rémi A.Arsenault, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6124 31-08-74 Q-1668 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking Q-500830° Normand Royer by virtue of his certificate 2.revokes certificate Q-500830 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Paul-Aimé Dumas, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind theCommission to issue such a permit. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, n° 44 8283 No Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Cote Décisions QCV-93 16-10-74 Q-500425 CHARLES LESSARD Requérant-cédant Applicant-transf error VIATEUR LAPOINTE Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Charles Lessard en vertu de son attestation Q-500425; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-500425; 3.autorise en faveur du requérant-cessionaire, Viateur Lapointe, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission à émettre tel permis.QCV-96 17-10-74 Q-502843 EDMOND GRONDIN Requérant-cédant A pplicant-transf error REJEAN CLOUTIER Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree La Commission: 1.autorise la suppression du service de camionnage en vrac donné par Edmond Grondin en vertu de son attestation Q-502843; 2.révoque à toutes fins que de droit l'attestation Q-602843 ; 3.autorise en faveur du requérant-cessionnaire, Réjcan Cloutier, la délivrance, sur paiement des frais requis, d'une attestation qui ne pourra être considérée comme un permis et n'engage pas la Commission k émettre tel permis.6126 31-08-74 Q-1677 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk 'rucking service provided by Charles Lessard by virtue of his certificate Q-500425; 2.revokes certificate Q-500245 for all legal purposes: 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Vialevr Lapointe.upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.6130 31-08-74 Q-1716 The Commission: 1.authorizes the discontinuance of the bulk trucking service provided by Edmond Grondin by virtue of his certificate Q-502843; 2.revokes certificate Q-502843 for all legal purposes; 3.authorizes the issue of a certificate in behalf of the applicant-transferee, Réjeon Cloutier, upon payment of the required charges; such certificate shall not be considered as a permit and does not bind the Commission to issue such a permit.QCR-820 QCR-821 QCR-824 QCR-826 QCR-827 QCR-828-TF 18-10-74 18-10-74 22-10-74 22-10-74 23-10-74 23-10-74 15-V-D-10 TRANSPORT D'ANJOU INC.Modification de permis Modification oj permit 16584-V-D-l EDDY DOYON ENR.(EDDY DOYON) Service additionnel / Additional service 5571-V-D-l FERNAND CREPEAU Requérant-vendeur Applicant vendor 69-V BOURRET TRANSPORT LIMITEE Requérante-acquéreur A pplicanl-purchascr 23615-V-D-l ABATTOIR ST-ALEX ANDRE LIMITEE Nouvelle demande / New application 10489-V-D-l OSCAR COUTURE Requérant-cédant A pplicant-transf errer 23982-V-D-l TRANSPORT N.G.B.INC.N.B.G.TRANSPORT INC.Requérant-cessionnaire Applicant-transferee 21166-V-D-l TF QUEVILLON TRANSPORT ENRG.Modification de tarifs Modification of tariffs 6316 6316 5645 6318 6870 7263 07-09-74 07-09-74 10-08-74 07-09-74 21-09-74 08-12-73 Q-1756 Q-1763 Q-1549 Q-1763 Q-1835 Q-446 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 8284 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tA pplicants\t\t\tCase\t QCR-829-TF\t23-10-74\t4639-V-D-l TF\t5446\t03-08-74\tQ-1496\tAccordée / Granted \t\tABITESK TRANSPORT ENRG.\t\t\t\t \t\t(DENIS PELLETIER) Modification de tarifs\t\t\t\t QCS-419-TF\t22-10-74\tModification of tariffs 13654-V-D-l-TF\t5930\t24-08-74\tQ-1605\tAccordée / Granted \t\tALBERT PELLETIER INC.\t\t\t\t \t\tALBERT PELLETIER THE MOVERS Modification de tarifs\t\t\t\t \t\tModification of tariffs\t\t\t\tAccordée / Granted QCS-420\t22-10-74\t16903-V-D-6\t6315\t07-09-74\tQ-1751\t \t\tCARTIER TRANSPORT INC.Modification de permis\t\t\t\t \t\tModification of permit\t\t\t\tAccordée / Granted QCS-421\t23-10-74\t23837-V-D-l\t5278\t27-07-74\tQ-1462\t \t\tCYRIL KILCOLLINS Voiturier- remorqueur Haulaway operator 13963-V SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Voiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QCS-422\t23-10-74\t23951-V-D-l\t5930\t24-08-74\tQ-1608\tAccordée / Granted \t\tROBERT LANTEIGNE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 13963-V SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Voiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t QPV-372-S\t23-10-74\t3U0-A-D-3\t6317\t07-09-74\tQ-1758\tAccordée / Granted \t\tRENE LETOURNEAU ENRG.\t\t\t\t QPV-373-\t23-10-74\t2977-AT D-l TF\t5446\t03-08-74\tQ-1494\tAccordée / Granted TF\t\tTAXI ST-LOUIS LIMITEE TAXI ST-LOUIS ENR.Modification de tarifs Modification of tarifs\t\t\t\t QL-196\t18-10-74\t1174-DYV-D-l\t6314\t07-09-74\tQ-1748\tAccordée / Granted \t\tD.BOURBEAU INTERNATIONAL LIMITEE Nouvelle demande / New application\t\t\t\t QL-196\t23-10-74\t287-DY & 37-DYV-D-l\t6319\t07-09-74\tQ-1768\tAccordée / Granted \t\tCHICOLTIMI DRIVE YOURSELF\t\t\t\t \t\tREG'D.\t\t\t\t MCR-1268\t23-10-74\t20752-V-D-l\t922\t26-01-74\tM-958\tRejetée / Rejected \t\tFERNAND COUPAL\t\t\t\t MCS-774\t18-10-74\t23450-V-D-2\t2325\t23-03-74\tM-1309\tAccordée / Granted \t\tNELSON EMOND\t\t\t\t MCS-776\t18-10-74\t19000-V-D-2\t2326\t23-03-74\tM-I311\tAccordée / Granted \t\tCOURTEMANCHE TRANSPORT\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t MCS-779\t22-10-74\t23646-V-D-l\t2491\t30-03-74\tM-1363\tDésistement MCS-787\t\tFRANK RAYMOND\t\t\t\tWithdrawal \t23-10-74\t77-V-D-l\t2635\t06-04-74\tM-1493\tDésistement \t\tP.E.LAFRAMBOISE TRANSPORT ENRG.\t\t\t\tWithdrawal MCS-788\t23-10-74\t23604-V-D-l\t2338\t23-03-74\tM-1353\t ML-433\t\tROBERT DUPONT Requérant / Applicant JOSEPH ELIE LTEE Requérante-conjointe Joint applicant\t\t\t\t Accordée en permis spécial partie, annule à toutes fins que de droit le émis le 17 mai 1974.Granted in permit issued 21-10-74 18-10-74 21-10-74 part; cancels, for ail on May 17, 1974.1084-DY V-D-l JOHN DE LA MARE 1948-A-D-2 UNCLE HARRYS BUS SERVICE INC.3024-A-D-l LES AUTOBUS BROMONT INC.1685 1678 2133 02-03-74 02-03-74 16-03-74 M-1178 M-1139 M-1220 legal purposes, the special Rejetée / Rejected Accordée en partie Granted in part Désistement Withdrawal GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1974, 106' année, n\" U 8285 No\tDate\tRequérants A pplicants\tC page\t.O.Q.date\tCause Case\tDécisions MPV-329 MPV-333\t21-10-74 23-10-74\t3361-A-D-l ANDRE RENAUD 1983-A NOEL MALO\t2143 3380\t16-03-74 02-06-73\tM-1254 M-4375\tRejetée / Rejected Accordée / Granted AUDIENCES PUBLIQUES \u2014 TRANSPORTS PUBLIC \u2014 ECOLIERS PUBLIC HEARINGS \u2014PUBLIC TRANSPORT \u2014 STUDENTS\t\t\t\t\t\t No\tDate\tRequérants Applicants\tJournal\tDate\tCause Case\tDécisions MPE-4\t23-10-74\tCOMMISSION SCOLAIRE LE GARDEUR Requérant / Applicant LES AUTOBUS HEBERT INC.Entrepreneur / Contracter\tLa Presse\t20.21 août August.\tM-2920\t La Commission fixe comme prix du contrat adjugé par le The Commission fixes as the price of the contract given out requérant à l'entrepreneur Les Autobus Hébert Inc.le prix by the applicant to the contractor.Les Autobus Hébert Inc., pour lequel l'entrepreneur a soumissionné, à savoir: that for which the contractor tendered, to wit: Parcours No 1 :\tS 14.298.00\tRoute No.\t1\tS 14,298.00 Parcours No 2:\t13,978.00\tRoute No.\t2\t13.978.00 Parcours No 3:\t14.298.00\tRoute No.\t3\t14,298.00 Parcours No 4 :\t13.644.00\tRoute No.\t4\t13.644.00 Parcours No 5:\t13,978.00\tRoute No.\t5\t13,978.00 Parcours No 6:\t13,978.00\tRoute No.\t6\t13.978.00 Parcours No 7:\t13.978.00\tRoute No.\t7\t13.978.00 Parcours No 8:\t14.488.00\tRoute No.\t8\t14.488.00 Parcours No 9 :\t13.036.00\tRoute No.\t9\t13,036.00 Parcours No 10:\t13,978.00\tRoute No.\t10\t13,978.00 Parcours No 11:\t13.254.00\tRoute No.\t11\t13,254.00 Parcours No 12:\t13.978.00\tRoute No.\t12\t13 .978.00 Parcours No 15:\t14.393.00\tRoute No.\t15\t14,393.00 Parcours No 24:\t15.300.00\tRoute No.\t24\t15.300.00 Parcours No 25:\t15.300.00\tRoute No.\t25\t15,300.00 Parcours No 27:\t13,978.00\tRoute No.\t27\t13,978.00 Parcours No 28:\t14.393.00\tRoute No\t28\t14.393.00 Parcours No 29:\t13,978.00\tRoute No.\t29\t13,978.00 Parcours No 30:\t14,393.00\tRoute No.\t30\t14,393.00 Parcours No 31 :\t14,763.00\tRoute No\t31\t14 ,763.00 Parcours No 32:\t14,763.00\tRoute No.\t32\t14,763.00 Parcours No 33:\t14.393.00\tRoute No.\t33\t14,393.00 Parcours No 34:\t14.298.00\tRoute No.\t34\t14,298.00 Parcours No 35:\t13,978.00\tRoute No\t35\t13,978.00 Parcours No 36:\t14.763.00\tRoute No.\t36\t14,763.00 Parcours No 37 :\t16,664.00\tRoute No.\t37\t16,664.00 Parcours No 38:\t15.300.00\tRoute No.\t38\t15,300.00 Parcours No 39:\t15,847.00\tRoute No.\t39\t15.847.00 Parcours No 40:\t14.488.00\tRoute No.\t40\t14,488.00 Parcours No 41:\t16.619.00\tRoute No\t41\t16,619.00 Parcours No 42 :\t14,393.00\tRoute No.\t42\t14,393.00 Parcours No 43:\t14,298.00\tRoute No.\t43\t14.298.00 Parcours No 44 :\t14.488.00\tRoute No\t44\t14,488 00 Parcours No 45:\t15.033.00\tRoute No.\t45\t15,033.00 Parcours No 46 :\t13.644.00\tRoute No.\t46\t13,644.00 Parcours No 47:\t14.393.00\tRoute No\t47\t14,393.00 Parcours No 48:\t14.488.00\tRoute No.\t48\t14.488.00 Parcours No 49:\t15,033.00\tRoute No.\t49\t15,033.00 Parcours No 50:\t14,763.00\tRoute No.\t50\t14.763.00 Parcours No 51:\t14,763.00\tRoute No.\t51\t14.763.00 Parcours No 52 :\t14.488.00\tRoute No.\t52\t14.488.00 Parcours No 53:\t14,763.00\tRoute No.\t53\t14,763.00 Parcours No 54:\t14.763.00\tRoute No.\t54\t14.763.00 Parcours No 55 :\t14,393.00\tRoute No.\t55\t14.393.00 Parcours No 56:\t13.644.00\tRoute No.\t5fi\t13.644.00 Parcours No 57 :\t13.978.00\tRoute No.\t57\t13,978.00 s2sr, QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Parcours Parcours Parcours Parcours Parcours Parcours Parcours Parcours No 58 No No 60 No 61 No 62 No 63 No 64 No 65 $12.750 00 14.763 00 13,136 00 14.624 00 15.300 00 13.136 00 12.384.00 13.136 00 Route Route Route Route Route Route Route Route No.58 No.59 No.60 No.61 No.62 No.63 No.64 No.65 $12.750 00 14.763 00 13.136 00 14.624 00 15,300.00 13.136 00 12.384.00 13,136.00 AUDIENCES PUBLIQUES \u2014 TRANSPORTS PUBLIC \u2014 ECOLIERS PUBLIC HEARINGS \u2014 PUBLIC TRANSPORT \u2014 STUDENTS No\tDate\tRequérant Applicant\t\tCause MPE-2\t16-10-74\tM-100-006-D-1-1\t\tM-2824 \t\tCOMMISSION SCOLAIRE REGIONALE SALABERRY\t\t \t\tRequérante / A pplicant\t\t \t\tROGER MYRE\t\t \t\tEntrepreneur / Contractor\t\t Détail de la demande et de la décision:\t\t\tParticulars of application and decision:\t Demande parue dans\t\tc journal « La Presse \u2022 les 20, 21\tApplication published in the newspaper \"La\tPresso\" on août 1974.\t\t\tAugust 20 and 21, 1974.\t La commission fixe comme prix du contrat adjugé par la\t\t\tThe Commission fixes the price for which the contractor\t requérante a l'entrepreneur le prix pour lequel l'entrepreneur\t\t\ttendered as the price of the contract awarded to the contractor\t a soumissionné à savoir:\t\t\tby the applicant, to wit:\t Parcours\tNo 7:\t$13,231\tRoute No.7:\t113,231 Parcours\tNo 8:\t12,632\tRoute No.8:\t12,632 Parcours\tNo 9:\t15.911\tRoute No.9:\t15.911 Parcours No 41 :\t\t12,383\tRoute No.41 :\t12,383 Parcours\tNo 42:\t12,632\tRoute No.42:\t12,632 Parcours\tNo 80:\t14,157\tRoute No.80:\t14,157 MPE-3 16-10-74 M-100-006-D-1-5 COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE SALABERRY Requérante / Applicant ANTONIO DANDURAND Entrepreneur / Contractor Détail do la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « La Presse » les 20, 21 août 1974.La commission fixe comme prix du contrat adjugé par la requérante à 1'ontrepreneur le prix pour lequel l'entrepreneur a soumissionné à savoir: Parcours No 44: $11,860 M-2824 Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"La Presso\" on August 20 and 21 1974.The Commission fixes the price for which the contractor tendered as the price of the contract awarded to the contractor by the applicant, to wit: Route No.44: $11,860 SEANCES EN CHAMBRE/SITTINGS IN CHAMBERS \t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\t\tRequérants\t\t\tCause\t \tDate\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCose\t MCR-1249-TF\t17-10-74\t30003-D-39-TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.\t5470\t03-08-74\tM-2731\tAccordée / Granted MCR-1260-\t17-10-74\t30006-D-20-TF\t5460\t03-08-74\tM-2676\tAccordée / Granted TF\t\tNIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.\t\t\t\t MCR-1251-\t17-10-74\t30004-D-21-TF\t5460\t03-08-74\tM-2674\tAccordée / Granted TF\t\tCANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N\t\t\t\t MCR-1252-\t17-10-74\t30004-D-16-TF\t4471\t15-06-74\tM-2190\tAccordée / Granted TF\t\tCANADIAN TRANSPORT TARIFF\t\t\t\t MCS-770-\t\tBUREAU ASS'N\t\t\t\t TF\t\t\t\t\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974.106' année, n° 44 8287 Nu Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions MCR-1253- TF MCS-771- TF MCR-1255- TF MCR-1257- TF MCR-1258 MCR-1259 MCR-1260- TF MCS-777- TF MCR-1269 17-10-74 18-10-74 18-10-74 18-10-74 21-10-74 21-10-74 30004-D-IS-TF CANADIAN TRANSPORT TARIFF BUREAU ASS'N 9011-V-D-l-TF VERDUN TRUCKING CO.LTD.17673-V-D-l-TF GABRIEL YERGEAU 14995-V-D-l WINDSOR WOOD CHIP COMPANY LTD.Requérante-venderesse A pplicant-vrndor R.B.D.TRANSPORT INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser 23848-V-D-l RICHARD CODERRE 8123-V-D-2-TF JOHN N.BROCKLESBY TRANSPORT LTD.4169 5545 4136 4133 4991 5459 4996 15-06-74 03-08-74 01-06-74 01-06-74 13-07-74 03-08-74 13-07-74 M-2189 M-2608 M-2043 M-2032 M-2386 M-2673 M-2402 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 23-10-74 12400-V-D-l IRENE DAOUST PLANTE Requérante-venderesse A pplicant-rendor L.PLANTE TRANSPORT INC.Requérant-acquéreur A pplicant-pvrchaser MCR-1270- 23-10-74 21136-V-D-l-TF TF GREAT WEST TRANSPORT CO.Référant à la décision MCR-720-TF datée du 20 février 1974 / 7n reference to decision MCR-7S0-TF dated February SO.1974.La Commission accorde pour fin d'administration, un délai For administrative purposes, the Commission grants de douze jours à compter du 20/2/74 twelve-day extension beginning 20/2/74.MCR-1271 MCS-772 MCS-773 MCS-778 MCS-780-TF MCS-789 23-10-74 18-10-74 18-10-74 22-10-74 22-10-74 23-10-74 5415-V-D-l HERVE VENNE Requérant-vendeur / Applicant-vendor LAURENT VENNE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser 23751-V-D-l ROBIN FORTIN Voiturier-remorqueur Haulaway operator 8565-V CENTRAL TRUCK LINES LTD.Voiturier-roulier / Carrier 23871-V-D-l POCE CONSTRUCTION LIMITED 20611-VM-D-l ARROW CARTAGE Requérant-vendeur / Applicant-vendor BLUE BIRD MOVING & STORAGE LTD.Requérante-acquéreur A pplicant-purchaser 14487-V-D-l-TF PENNOAK CHEMICAL TRANSPORT LIMITED 1930-V PROVOST CARTAGE INC.Voiturier-roulier / Carrier 23839-V-D-l GERARD MARTIN Voiturier-remorqueur Haulaway operator 4638 4120 5001 4793 5157 5013 22-06-74 01-06-74 13-07-74 29-06-74 20-07-74 13-07-74 M-2220 M-2010 M-2426 M-2318 M-2503 M-245S Accordée / Granted Désistement Withdrawal Désistement Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 8288 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.U \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\t\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\tCase\t ML-429\t21-10-74\t798-DY & 1132-DYV-D-l\t4660\t22-06-74\tM-2309\tAccordée / Granted \t\tNELSON FOURNIER INC.\t\t\t\tAccordée / Granted ML-430\t21-10-74\t1142-DYV-D-l\t4660\t22-06-74\tM-230S\t \t\tAPOLLO LEASING LTD.\t\t\t\tAccordée./ Granted ML-431\t21-10-74\t889-DYV & 1180-DY-D-l\t4988\t13-07-74\tM-2306\t \t\tJ.E.GENDRON AUTOMOBILE LTEE\t\t\t\tAccordée / Granted MPV-32S-S-\t21-10-74\t602-A-TF-9\t6136\t31-08-74\tM-2868\t TF\t\tSERVICE DE LIMOUSINE\t\t\t\t MPV-330-S\t21-10-74\tMURRAY HILL LTEE 3575-A-D-l\t4795\t29-06-74\tM-2321\tAccordée / Granted MPV-331-\t22-10-74\tROBERT AVBUCHON 602-A (MTF-11)\t6151\t31-08-74\tM-2908\tAccordée / Granted TF\t\tSERVICE DE LIMOUSINE\t\t\t\t \t\tMURRAY HILL LTEE\t\t\t\t MPV-332-\t22-10-74\t602-A (MTF-11)\t6151\t31-08-74\tM-2907\tAccordée / Granted TF\t\tSERVICE DE LIMOUSINE\t\t\t\t \t\tMURRAY HILL LTEE\t\t\t\tAccordée / Granted MSM-1S-\t18-10-74\tCLARKE MARITIME LTEE\t5474\t03-08-74\tM-2732\t TF\t\tCLARKE STEAMSHIP LTD.\t\t\t\t PERMIS SPECIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.\tNom du requérant Name of Applicant\tPériode do validité Period of validity MS-1101\tCause: MRS-0554\t 1366-DY\tJOHN FORSYTH\t 1188-DYV-S-l\t\t Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir n les 20, 21 et 22 septembre 1974.Rejetée.MS-1102 1184-DYV-S-l Cause: MRS-0533 MARCEL FERLAND Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir septembre 1974.Accordée.les 9, 10 et 11 Cause: MRS-0545 VIAU DRIVE YOURSELF INC.MS-1103 82-DYV 445-DY-S-l Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Montréal-Matin n les 21, 22 et 23 septembre 1974.Accordée.MS-1104-S Cause: MRS-0553 3108-A-S-4 J.C.MINIBUS ENRG.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Montréal-Matin » les 14, 15 et 16 septembre 1974.Accordée.MS-1106 Cause: MRS-0552 2186-A-S-3 HUGUETTE LEBOEUF Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Montréal-Matin » les 21, 22 et 23 août 1974.Rejetée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on September 20, 21 and 22, 1974.Rejected.Du 8 octobre 1974 au 7 octobre 1975 ou décision finale./ From October S, 1974 to October 7, 1976 or until final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" newspaper on September 9, 10 and 11, 1974.Granted.Du 15 octobre 1974 au 14 octobre 1975 ou décision finale./ From October 15.1974 to October 14, 1976 or until final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal-Matin\" newspaper on September 21, 22 and 23, 1974.Granted.De Septembre 1974 à juin 1975./ From September 1974 to June 1976.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal-Matin, newspaper on September 14.15 and 16, 1974.Granted.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal-Matin\" newspaper on August 21, 22 and 23, 1974.Rejected. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, s novembre 1974, 106' année, n\" 44 8289 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tPériode de validité Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tPeriod of validity MS-1107 24004-V-S-l\tCause: MRS-0530 CHARLES-EMILE BOISVERT\tDu 21 septembre 1974 au 20 octobre 1975 ou décision finale./ From September SI, 197i to October SO, 1976 or until final decision.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Montréal-Matin » les 16, 17 et 18 septembre 1974.Accordée.Cause: MRS-0570 ROBERT H.LAFRANCE LTEE MS-1108 20829-V-S-l Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour » les 28, 30 septembre et 1er octobre 1974.Accordée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal-Matin\" newspaper on September 16, 17 and 18, 1974.Granted.Du 18 octobre 1974 au 15 novembre 1974./ From October IS.1974 to November 16.1974- Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on September 28.30 and October 1, 1974.Granted.QS-636 Q-504600-S-006 Cause: Q-649 CAMIONNAGE BLACKBURN 4 FILS ENR.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2, 3 and 4th, 1974.Rejected.Cause: Q-648 CAMIONNAGE BLACKBURN & FILS ENR.QS-637 Q-50460O-S-OO5 Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.Particulars of appl ication and decision : Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2, 3 and 4th, 1974.Rejected.Cause: Q-647 CAMIONNAGE BLACKBURN A FILS ENR.QS-638 Q-504600-S-004 Déails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2.3 and 4th.1974.Rejected.Cause: Q-646 CAMIONNAGE BLACKBURN & FILS ENR.QS-639 Q-504600-S-003 Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal o Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.Particulars of application and decision^ Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2.3 and 4th, 1974.Rejected.Cause: Q-645 CAMIONNAGE BLACKBURN & FILS ENR.QS-640 Q-504600-S-O02 Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.Particulars of application and decision^ Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2, 3 and 4th, 1974.Rejected.Cause ' Q\u2014644 CAMIONNAGE BLACKBURN A FILS ENR.QS-641 Q-504600-S-001 Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Quotidien » les 2, 3 et 4 octobre 1974.Rejetée.QS-642 Q-3310-A-S-1 Cause: Q-637 ALBERT FILLION Détails de la demande et de la décision : Demande parue dans le journal « Le Soleil » les 1er, 2 et 3 octobre 1974.Accordée.Particulars of application and decision:^ Application published in the \"Le Quotidien\" on October 2.3 and 4th.1974.Rejected.Service No 1 : A compter de septembre 1974 à juillet 1975.From September 1974 to July 1976.Service No 2 : A compter d'octobre 1974 jusqu'à juillet 1975.From Oct ober 19741 o July 1976.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Soleil\" on October 1st, 2, and 3rd, 1974.Granted. 8290 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.QS-643 22811-V-S-2 6793-V Nom du requérant Mime of Applicant Cause: Q-639 CHARLES A.BOUCHER Voiturier-remorqueur / Haulaway operator BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Période de validité Period of validity Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Devoir » le 30 septembre, les 1er et 2 octobre 1974.Accordée.Du 11 octobre 1974 au 10 octobre 1975, ou jusqu'à décision finale de la Commission, selon 1 éventualité qui se présentera la première.From October 11th, 1974 to October 10th.1976 or until final decision of the Commission whichever shall occur first.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Devoir\" on September 30 and October 1st and 2nd, 1974.Granted.QS-644-TF Cause: Q-642 00002-MTF-6 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AUTOBUS DU QUEBEC pour / for AUTOBUS FORTIN 4 POULIN INC.Modification de tarifs/ Modification of tariffs Détails de la demande et de la décision: Particulars of application and decision: Demande parue dans le journal « Journal de Québec » les Application published in the \"Le Journal de Québec on 17, 18 et 19 septembre 1974.September 17,18 and 19th, 1974.Accordée.Granted.QS-645 23747-V-S-2 6793-V Cause: Q-640 ROLAND VACHON Voiturier-remorqueur / Haulaway operator BRAZEAU TRANSPORT INC.Voiturier-roulier / Carrier Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal t Le Devoir \u2022 les 27.28 et 30 septembre 1974.Accordée.Du 11 octobre 1974 au 10 octobre 1975 ou jusqu'à décision finale de la Commission, selon 1 éventualité qui se présentera la première.From October 11th, 1974 to October 10th, 1976 or until final decision of the Commission whichever shall occur first.Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"Le Devoir\" on September 27, 28 and 30th.1974.Granted.QS-646 13408-V-S-l Cause: Q-650 AIR LINES TAXIS 4 BUSSES REG'D (Mme Yvonne Doré-Breton faisant affaires sous le nom de Operating under the name of) Requérant-vendeur / Applicant-vendor QUEBEC AIR LINES TAXIS 4 BUSSES SERVICE INC.Requérante-acquéreur / Applicant-purchaser Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal ¦ A Propos \u2022 les 27.28 et 29 juin 1974.Accordée.La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'à l'autorisation finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent.This transfer authorization is temporary and shall be valid until a final authorization is granted further to the request for authorization submitted by the applicants according to the procedure prescribed for the obtainment of a regular and permanent permit.Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"A Propos\" on June 27, 28 and 29th, 1974.Granted.QS-647-S 1389-A-S-3 Cause: Q-0638 AIR LINES TAXIS 4 BUSSES REG'D (Mme Yvonne Doré-Breton faisant affaires sous le nom de Operating under the name of) Requérant-vendeur/ Applicant-vendor QUEBEC AIR LINES TAXIS 4 BUSSES SERVICE INC.Requérante-acquéreur/ Applicant-purchaser Détails de la demande et de la décision : Demande parue dans le journal « A Propos \u2022 les 27, 28 et 29 juin 1974.Accordée.La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'à l'autorisation finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent.This transfer authorization is temporary and shall be valid until a final authorization is granted further to the request for atithorisation submitted by the applicants according to the procedure preecribed for the obtainment of a regular and permanent permit.Particulars of application and decision: Application published in the newspaper \"A Propos\" on June 27.28 and 29th.1974.Granted.QS-648-S 3596-A-S-l Cause: Q-613 LA GARDERIE DRUMMOND (Mme Jeanne Pepin opérant sous le nom de / Operating under the name of) A compter du 7 octobre 1974 au 30 juin 1975 From October 7th, 1974 to June 30th.1976. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8291 Détails de la demande et de la décision: Particulars of application and decision: Demande parue dans le journal « Le Nouvelliste » les 11, 12 Application published in the \"Le Nouvelliste\" on Septem- et 13 septembre 1974.ber 11, 12 and 13th, 1974.Accordée.Granted.SEANCES EN CHAMBRES \u2014TRANSPORT PAR VEHICULE-TAXI SITTINGS IN CHAMBERS\u2014TRANSPORT BY TAXICAB \t\t\tDemande de\t\tpermis\t\t \t\t\tApplication of permit\t\t\t\t \t\tRequérant\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\t\t\t\t\tDécisions \t\tApplicant\tCatégorie\tAggl.\t\tCase\t \t\t\t\t\tRégion\t\t \t\t\tCiasj\tCongl.\t\t\t QPT-2344\t22-10-74\tQ-200844-D-1\tOrdinaire\tA-47\tMatagami\tQT-2298\tAccordée \t\tMARCEL LANDRY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2345\t22-10-74\tQ-201718\tOrdinaire\tA-20\tAima\tQT-2305\tAccordée \t\tYVON MARTEL\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2346\t22-10-74\tQ-200029\tOrdinaire\tA-38\tSte-Foy -\tQT-2309\tAccordée \t\tRENALD DROLET\tOrdinary\t\tSillery\t\tGranted QPT-2347\t22-10-74\tQ-200012-D-001\tOrdinaire\tA-35\tLévis - Lauzon\tQT-1401\tAccordée \t\tFLORIAN CADORET\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2348\t22-10-74\tQ-200143\tOrdinaire\tA-53\tSept-Iles\tQT-2308\tAccordée \t\tREAL VIGNEAULT\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2349\t22-10-74\tQ-200272\tOrdinaire\tA-42\tShawinigan\tQT-2299\tAccordée \t\tANTONIO LANNEVILLE\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2350\t22-10-74\tQ-201932\tOrdinaire\tA-22\tHauterive\tQT-2301\tAccordée \t\tWILBROD GAGNE\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2351\t22-10-74\tQ-200756\tOrdinaire\tA-36\tQuébec\tQT-2300\tAccordée \t\tROLAND TREMBLAY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2352\t22-10-74\tQ-201992\tOrdinaire\tA-25\tCharlesbourg -\tQT-2304\tAccordée \t\tGASTON QUIRIAULT\tOrdinary\t\tOrsainville\t\tGranted QPT-2353\t22-10-74\tQ-201715\tOrdinaire\tA-50\tLa Tuque\tQT-2303\tAccordée \t\tPAUL EUGENE\tOrdinary\t\t\t\tGranted \t\tGENDRON\t\t\t\t\t QPT-2354\t22-10-74\tQ-201716\tOrdinaire\tA-50\tLa Tuque\tQT-2302\tAccordée \t\tREJEAN CAYER\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2355\t23-10-74\tQ-201505-D-O02\tOrdinaire\t\tSenneterre\tQT-2310\tAccordée \t\tCLAUDE\tOrdinary\t\t\t\tGranted \t\tCOURTEMANCHE\t\t\t\t\t QPT-2356\t23-10-74\tQ-201505-D-001\tOrdinaire\t\tSenneterre\tQT-2311\tAccordée \t\tCLAUDE\tOrdinary\t\t\t\tGranted \t\tCOURTEMANCHE\t\t\t\t\t QPT-2357\t23-10-74\tQ-200444\tOrdinaire\tA-36\tQuébec\tQT-2313\tAccordée \t\tJEAN CLAUDE\tOrdinary\t\t\t\tGVanred \t\tBELANGER\t\t\t\t\t QPT-2358\t23-10-74\tQ-200443\tOrdinaire\tA-25\tCharlesbourg -\tQT-2314\tAccordée \t\tROCH EMILE DUPONT\tOrdinary\t\tOrsainville\t\tGranted QPT-2359\t23-10-74\tQ-200343-D-O01\tOrdinaire\tA-20\tAima\tQT-2315\tAccordée \t\tADELARD TREMBLAY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2360\t23-10-74\tQ-200343-D-O02\tOrdinaire\tA-20\tAima\tQT-2316\tAccordée \t\tADELARD TREMBLAY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2361\t23-10-74\tQ-200343-D-O03\tOrdinaire\tA-20\tAima\tQT-2317\tAccordée \t\tADELARD TREMBLAY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2362\t23-10-74\tQ-200343-D-O04\tOrdinaire\tA-20\tAima\tQT-2318\tAccordée \t\tADELARD TREMBLAY\tOrdinary\t\t\t\tGranted QPT-2363\t23-10-74\tQ-200574-D-001\tOrdinaire\tA-51\tL'Ouest du\tQT-2312\tAccordée \t\tRENE BLACKBURN\tOrdinary\t\tSaguenay\t\tGranted QPT-2364\t23-10-74\tQ-200170-D-001\tOrdinaire\t\t8t-Eleuthère\tQT-0406\tAccordée \t\tLEON FRECHETTE\tOrdinary\t\t\t\tGranted 58870-o S292 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Avis divers Municipalité de la cité de Jonquiëre Municipalité de la cité de Kénogami Municipalité de la ville d'Arvida Municipalité de la paroisse Saint-Dominique-de-Jonquière Avis est par les présentes donné que le conseil de la municipalité de la cité de Jonquière, le conseil de la municipalité de la cité de Kénogami et le conseil de la municipalité de la paroisse Saint-Dominique-de-Jonquière ont adopté, à la majorité de leurs membres, des règlements, soit le règlement numéro 861 de la municipalité de la cité de Jonquière, le règlement numéro 455 de la municipalité de la Cité de Kénogami et le règlement numéro 222 de la municipalité de la paroisse Saint-Dominique-de-Jonquière, autorisant ces municipalités à présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour fusionner les municipalités de la cité de Jonquière, de la cité de Kénogami, de la ville d'Arvida et de la paroisse Saint-Dominiquc-de-Jonquière et créer la nouvelle municipalité de « Ville de Jonquière » aux conditions suivantes: A l'honorable lieutenant-gouverneur en conseil.Les Cités de Jonquière et de Kénogami et La Municipalité de la Paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière.Requérantes Exposent respectueusement 1.Attendu que la loi favorisant le regroupement des municipalités, chapitre 53 des lois de 1971, prévoit 3u'à l'intérieur d'une unité de regroupement, la moitié es conseils représentant au moins la moitié de la population de l'unité de regroupement peut adopter un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au lieutenant-gouverneur en conseil le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant les municipalités de l'unité de regroupement; 2.Attendu qu'une unité de regroupement a été établie pour les cités de Jonquière et de Kénogami, la ville d'Arvida et pour la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière; 3.Attendu que les conseils des cités de Jonquière et de Kénogami et de la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière représentent plus de la moitié des conseils et de la population de l'unité de regroupement\", 4.Attendu que les conseils des cités de Jonquière et de Kénogami et de la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière ont adopté un tel règlement; En conséquence, vos requérantes vous prient d'octroyer des lettres patentes fusionnant les cités de Jonquière et de Kénogami, la ville d'Arvida et la municipalité de la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière, selon les modalités suivantes: Miscellaneous Notices Municipality of the City of Jonquière Municipality of the City of Kénogami Municipality of the City of Arvida Municipality of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière Notice is hereby given that the Municipal Council of the City of Jonquière, the Municipal Council of the City of Kénogami and the Municipal Council of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière have adopted, by the majority of their members, bylaws, namely Bylaw number 861 of the Municipality of the City of Jonquière, Bylaw number 455 of the Municipality of the City of Kénogami and Bylaw number 222 of the Municipality of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière, authorizing these municipalities to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council for the amalgamation of the Municipalities of the City of Jonquière, of the City of Kénogami, of the City of Arvida and of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière and for the creation of the new Municipality of the \"City of Jonquière\", under the following conditions: To the Honourable Lieutenant-Governor in Council.The Cities of Jonquière and Kénogami and The Municipality of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquiere.Petioners Respectfully submit 1.Whereas the Act to promote the regroupment of municipalities, Statutes of 1971, Chapter 53, provides that within a regroupment unit, one half of the Councils representing at least one half of the population of the regroupment unit may adopt a bylaw authorizing the presentation of a joint petition to the Lieutenant-Governor in Council, praying him to issue letters patent amalgamating the municipalities of the regroupment unit; 2.Whereas a regroupment unit has been established for the City of Jonquière and the City of Kénogami, the City of Arvida and the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière ; 3.Whereas the Councils of the Cities of Jonquière and Kénogami and of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière represent more than one half of the Councils ana more than one half of the population of the regroupment unit; 4.Whereas the Councils of the Cities of Jonquière and Kénogami and of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière have adopted such a bylaw; Therefore, your petitioners are praying you to issue letters patent amalgamating the Cities of Jonquière and Kénogami, the City of Arvida and the Municipality of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière, according to the following terms and conditions: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 1) Le nom de la nouvelle ville est Jonquière; toutefois le premier conseil permanent devra, au cours de son mandat, procéder à une consultation populaire concernant le nom de la nouvelle ville.2) Le territoire de la nouvelle ville est celui déterminé par la description technique et le plan sur toile préparés par M.E.D.Cbiasson, a.g., en date du 15 du mois de janvier 1973, en annexe « A» de la présente pour en faire partie comme si elle était au long reproduite.3) La nouvelle municipalité est régie par la loi des cités et villes.4) Les dispositions législatives suivantes s'appliqueront à la nouvelle ville ; a) Dispositions législatives de la charte de la cité de Jonquière : - Les articles 426e, 426/ et 426?de la loi des cités et villes, édictés, pour la cité de Jonquière, par l'article 22 du chapitre 80 des Lois de 1955/56; - Le paragraphe 27°h de l'article 429 de la Loi des cités et villes, édicté, pour la cité de Jonquière, par l'article 24 du chapitre 80 des Lois de 1955/56; - Les articles 25, 26 et 27 du chapitre 80 des Lois de 1955-56; - L'article 526 de la Loi des cités et villes, édicté, pour la cité de Jonquière, par l'article 29 du chapitre 80 des Lois de 1955/56; - L'article 33 du chapitre 80 des Lois de 1955/56, tel que remplacé par l'article 6 du chapitre 63 des Lois de 1957/58; - L'article 3 du chapitre 63 des Lois de 1957/58; - L'article 37 et 38 du chapitre 80 des Lois de 1955/56, tels qu'ajoutés par l'article 4 du chapitre 63 des Lois de 1957/58; - L'article 41 du chapitre 80 des Lois de 1955/56, tel qu'ajouté par l'article 7 du chapitre 63 des Lois de 1957/58; - Les articles 4 et 5 du chapire 72 des Lois de 1962; b) Dispositions législatives de la charte de la ville d'Arvida; - Les articles 44, 48, 55 et 66 du chapitre 78 des Lois de 1926; - L'article 5 du chapitre 99 des Lois de 1950.5) Jusqu'à la première élection générale, le Conseil provisoire sera composé de tous les membres des quatres conseils existant avant, la fusion.Le quorum sera de la moitié plus un des membres de ce Conseil provisoire.Le premier maire de la nouvelle ville sera le maire de l'ancienne cité de Kénogami pour le premier quart de la durée du Conseil provisoire, le maire de l'ancienne municipalité de la paroisse Saint-Dominique-de-Jonquière pour le deuxième quart, le maire de l'ancienne cité de Jonquière pour le troisième quart, et le maire de l'ancienne ville d'Arvida pour le quatrième quart.6) Un comité exécutif provisoire sera formé des 3uatre maires des municipalités concernées; le prévient de cet exécutif sera nommé avant chaque réunion ; le quorum sera de trois personnes; advenant le décès ou la démission d'un membre de ce comité exécutif (1) The name of the new City shall be Jonquière; however, during its first term of office, the first permanent Council shall hold a referendum concerning the name of the new City.(2) The territory of the new City shall be the one determined in the technical description and plan prepared by Mr.E.D.Chiasson, cj.l.s., dated January 15.1973.Said documents are appended to these presents as Schedule \"A\", to form a part thereof, as if they were reproduced in full.(3) The new Municipality shall be governed by the Cities and Towns Act.(4) The following legal provisions shall apply to the new City: (a) Legal provisions of the Charter of the City of Jonquière: - Sections 426e, 426/ and 426o of the Cities and Towns Act, enacted, for the City of Jonquière, by section 22 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56; - Subsection 27 \"h of section 429 of the Cities and Towns Act, enacted, for the City of Jonquière, by section 24 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56; - Sections 25, 26 and 27 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56; - Section 526 of the Cities and Towns Act, enacted, for the City of Jonquière, by section 29 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56; - Section 33 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56, as replaced by section 6 of Chapter 63 of the Statutes of 1957/58; - Section 3 of Chapter 63 of the Statutes of 1957/58; - Section 37 and 38 of Chapter 80 of the Statutes of 1955/56, as added under section 4 of Chapter 63 of the Statutes of 1957-58; - Section 41 of Chapter 80, Statutes of 1955/56, added under section 7 of Chapter 63 of the Statutes of 1957/ 58; - Sections 4 and 5 of Chapter 72, Statutes of 1962; (6) Legal provisions of the Charter of the City of Arvida : - Sections 44, 48, 55 and 66 of Chapter 78 of the Statutes of 1926; - Section 5 of Chapter 99 of the Statutes of 1950.(5) Until the first general election, the Provisional Council shall be composed of all the members of the four Councils existing prior to the amalgamation.One half plus one of the members of said Provisional Council shall constitute a quorum.The first Mayor of the new City shall be the Mayor of the former City of Kénogami for the first quarter of the term of the Provisional Council, the Mayor of the former Municipality of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière for the second quarter, the Mayor of the former City of Jonquière for the third quarter, and the Mayor of the former City of Arvida for the fourth quarter.(6) A Provisional Executive Committee shall be composed of the four mayors of the municipalities concerned; the Chairman of this Executive shall be appointed before each meeting; the quorum shall consist of three persons; in the event of the death or resignation 8294 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 provisoire, son remplaçant sera choisi parmi ceux de l'ancienne municipalité dont il était le maire par le conseil provisoire.7) Le comité exécutif provisoire prépare et soumet au conseil: a) Tous les règlements.b) Le budget annuel.c) Toute demande pour l'affectation du produit des emprunts ou pour tout autre crédit requis.d) Toute demande pour virements de fonds ou de crédits déjà votés.e) Tout rapport recommandant l'octroi de franchises et de privilèges./) Tout rapport se rapportant à l'échange ou à la location par bail emphytéotique d'un immeuble appartenant à la ville et en outre à la location de ses biens-meubles ou immeubles lorsque la durée du bail excède un an.g) Toute autre demande dont l'objet n'est pas déclaré être de la compétence exclusive du comité exécutif.h) Tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s'y rattachent.8) Le comité exécutif provisoire doit veiller à ce que la loi, les règlements, les résolutions et les contrats de la ville soient fidèlement observés.9) Le comité exécutif provisoire veille à la préparation des plans et devis et à la demande de soumissions.10) Toute communication entre le conseil et les services se fait par l'entremise du comité exécutif provisoire; dans ses rapports avec celui-ci, le conseil doit toujours agir par résolution.Les membres du conseil ne doivent s'adresser qu'au gérant pour tout renseignement concernant les services.11) Toute communication entre le comité exécutif provisoire et les services se fait par l'entremise du érant; cependant, le comité exécutif provisoire a le mil.en tout temps, de faire venir devant lui tout directeur de service pour obtenir tous les renseignements qu'il désire.12) La présence du gérant ou de son remplaçant autorisé est obligatoire pour toute réunion du comité exécutif provisoire.13) Le greffier de la ville ou son représentant autorisé est d'office secrétaire du comité exécutif provisoire.14) La première séance du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à 8r00 p.m.en la salle de l'Hôtel de Ville de Kénogami et sans autre convocation.15) I* greffier de la nouvelle ville sera le greffier de l'ancienne ville d'Arvida conformément à l'article 5G de la loi favorisant le regroupement des municipalités, chapitre 53 des Lois 1971.16) La première élection générale aura lieu le troisième dimanche du quatrième mois suivant celui de l'entrée en vigueur des lettres patentes, mais en of a member of this Provisional Executive Committee, his replacement shall be chosen by the Provisional Council from among those (members) of the former municipality of which he was Mayor.(7) The Provisional Executive Committee shall prepare and submit to the Council: (a) All the bylaws.(6) The annual budget.(c) Any request for the allotment of the proceeds from loans or for any other supplies required.(d) Any request for the transfer of funds or of supplies already voted upon.(e) Any report recommending the granting of franchises and privileges.(/) Any report concerning the exchange or' renting, on a long-lease basis, of an immoveable belonging to the City and, moreover, the renting of its moveable or immoveable property, when the duration of such lease exceeds one year.(g) Any other request of which the object is not declared to be within the exclusive jurisdiction of the Executive Committee.(h) Any plan classifying the offices and the salaries attached thereto.(8) The Provisional Executive Committee shall see to it that the law, and that the bylaws, resolutions and contracts of the City are faithfully observed.(9) The Provisional Executive Committee shall see to the preparation of plans and specifications and to requests for tenders.(10) Any communication between the Council and the services shall be made through the Provisional Executive Committee; in its dealings with the latter, the Council shall act always by resolution.The members of the Council shall only address the manager for any information with regard to services.(11) Any communication between the Provisional Executive Committee and the services shall be made through the Manager; however, the Provisional Executive Committee has the right, at any time, to bring before it any department director in order to obtain all the information it desires.(12) The presence of the Manager or his authorized replacement is obligatory at any meeting of the Provisional Executive Committee.(13) The presence of the Clerk or his authorized replacement shall be ex officio of the Provisional Executive Committee.(14) The first meeting of the Provisional Council shall be held on the second Monday following the coming into force of the letters patent, at 8 o'clock p.m.in the chambers of Kénogami City Hall and without further notice.(15) The Clerk of the new City shall be the Clerk of the former City of Arvida, in conformity with section 5G of the Act to Promote the Regroupment of Municipalities, Chapter 53 of the Statutes of 1971.(16) The first general election shall be held on the third Sunday of the fourth month following that of the coming into force of the letters patent, but at no time GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ê novembre 1971,, 106' année, n° U 8295 aucun temps plus tôt, au cours d'un exercice financier, que le troisième dimanche du mois de mai.17) À compter de la première élection générale, le nombre des membres du conseil de la nouvelle ville sera de 15 personnes, dont un maire et quatorze conseillers.Toutefois à compter de la deuxième élection générale le nombre des membres du conseil sera de 9 personnes dont 1 maire et 8 conseillers.18) Le territoire de la nouvelle ville sera divisé, pour la première élection générale, en sept quartiers portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; chaque quartier aura deux sièges numérotés comme suit : le quartier numéro 1 possède les sièges numréos 1 et 2; le quartier numéro 2 possède les sièges numéros 3 et 4 ; le quartier numéro 3 possède les sièges numéros 5 et 6; le quartier numéro 4 possède les sièges numéros 7 et 8: le quartier numéro 5 possède les sièges numéros 9 et 10; le quartier numéro 6 possède les sièges numéros 11 et 12; le quartier numéro 7 possède les sièges numéros 13 et 14; La description technique de chacun des quartiers correspond à celle préparée par M.E.D.Chiasson, a.c, en date du 20 juillet 1974 et présentée en annexe « B » de la présente pour en faire partie comme si elle était au long reproduite.19) Le gérant de la municipalité a sous son autorité immédiate le coordonnâtes de la rénovation urbaine et responsable de la promotion, le gérant adjoint à l'administration et le gérant adjoint aux opérations.20) Le gérant adjoint à l'administration a sous son autorité immédiate le directeur du service du personnel et le directeur du service des finances.21) Le directeur du service des finances et trésorier au sens de la loi a sous son autorité immédiate les chefs des divisions de la comptabilité générale, de l'imposition et de la perception, du budget, et des approvisionnements et inventaires.22) Le gérant adjoint aux opérations a sous son autorité immédiate le directeur du service de planification, le directeur du service d'électricité, le directeur du service des travaux publics et le directeur du service des loisirs et parcs.23) Le directeur du service de planification a sous son autorité immédiate le chef de la division des relevés techniques, le chef de la division des projets d'égouts et d'aqueduc, le chef de la division du réseau routier, le chef de la division des permis de construction et le chef de la division de l'urbanisme.24) Le directeur du service des travaux publics a sous son autorité immédiate le chef de la division égouts et aqueduc, le chef de la division de la voirie, le chef de la division de la machinerie et le chef de la division des immeubles.earlier, during a fiscal year, than the third Sunday in the month of May.(17) From the first general election henceforth, the number of members of the new City council shall be 15 persons, including a Mayor and fourteen Councillors.However, commencing with the second general election the number of Council members shall be 9 persons, including a Mayor and 8 Councillors.(18) The territory of the new City shall be divided, for the purpose of the first general election, into seven wards bearing the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7; each ward shall have two seats numbered as follows: \u2014 Ward number one shall have seats numbers 1 and 2 ; Ward number two shall have seats numbers 3 and 4; Ward number three shall have seats numbers 5 and 6; Ward number four shall have seats numbers 7 and 8; Ward number five shall have seats numbers 9 and 10; Ward number six shall have seats numbers 11 and 12; Ward number seven shall have seats numbers 13 and 14; The technical description of each of the wards corresponds to the one prepared by Mr.E.D.Chiasson, Q.l.8., dated July 20, 1974 and presented in Schedule B to these presents, to become part of it as if it were reproduced in full.(19) The Manager of the Municipality shall have under his immediate authority the Coordinator of Urban Renovation and Officer Responsible for Promotion, the Assistant Manager of Administration and the Assistant Manager of Operations.(20) The Assistant Manager of Administration shall have under his immediate authority the Director of the Personel Department and the Director of the Finance Department.(21) The Director of the Finance Department and Treasurer, within the meaning of the law, shall have under his immediate authority the Heads of the General Accountancy, Taxation and Revenue, Budget and Supplies and Inventory Branches.(22) The Assistant Manager of Operations shall have under his immediate authority the Director of the Planning Department, the Director of the Electricity Department, the Director of the Public Works Department and the Director of the Recreation and Parks Department.(23) The Director of the Planning Department shall have under his immediate authority the Head of the Technical Surveys Branch, the Head of the Projects Branch for Sewer and Waterworks, the Head of the Road Network Branch, the Head of the Building Permits Branch and the Head of the Town-Planning Branch.(24) The Director of the Public Works Department shall have under his immediate authority the Head of the Sewers and Waterworks Branch, the Head of the Roads Branch, the Head of the Machinery Branch and the Head of the Real Estate Branch. QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974.Vol.106, No.44 25) Les articles 19 à 24 inclusivement ne prévaudront que pour une année à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes.26) Tous les officiers et employés permanents des quatre municipalités demeureront à l'emploi de la nouvelle ville, aux postes qui leur seront assignés, sous réserve des dispositions de la loi, et aux conditions suivantes; a) Le gérant de la cité de Jonquière devient le gérant de la nouvelle municipalité.6) Le trésorier de la ville d'Arvida devient le gérant adjoint i l'administration de la nouvelle municipalité.c) Le gérant de la cité de Kénogami devient le gérant adjoint aux opérations de la nouvelle municipalité.d) Le trésorier de la cité de Jonquière devient le directeur du service des finances de la nouvelle municipalité.e) Le greffier de la ville d'Arvida devient le grtffiei de la nouvelle municipalité./) Le gérant de la ville d'Arvida devient le directeur du service de planification de la nouvelle municipalité.g) Le directeur du service des travaux publics de la cité de Jonquière devient le directeur du service des travaux publics de la nouvelle municipalité.k) Le directeur du service des loisirs de la Cité de Jonquière devient le directeur du service des loisirs et parcs de la nouvelle municipalité.t) L'assistant-trésorier de la ville d'Arvida devient le chef de la division de la comptabilité générale de la nouvelle municipalité.j) Le secrétaire-trésorier de la cité de Kénogami devient le chef de la division de l'imposition et de la perception de la nouvelle municipalité.k) Le secrétaire-trésorier de la paroisse de Saint-Dominique-de-Jonquière devient le chef de la division des approvisionnements et inventaires de la nouvelle municipalité.I) Le coordonnateur de la rénovation urbaine et responsable de la promotion de la cité de Jonquière devient le coordonnateur de la rénovation urbaine et responsable de la promotion de la nouvelle municipalité.m) Le coordonnateur de la rénovation urbaine de la cité de Kénogami devient adjoint au coordonnateur de la rénovation urbaine et responsable de la promotion de la nouvelle municipalité.n) Le directeur du service de police de la ville d'Arvida devient le directeur du service de police de la nouvelle municipalité.o) Les directeurs de police et incendie des cités de Jonquière et de Kénogami deviennent directeurs adjoints du service de police de la nouvelle municipalité.p) Le greffier de la cité de Jonquière et l'assistant-greffier de la ville d'Arvida font partie du personnel-cadre du service du greffe et de l'information de la nouvelle municipalité.(25) Sections 19 to 24 inclusive shall be valid for one year only, commencing on the date of the coming into force of the letters patent.(26) All the officers and permanent employees of the four municipalities shall remain in the employ of the new City, in the positions which shall be assigned to them, subject to the provisions of the law, and on the following conditions; (a) The Manager of the City of Jonquière shall become Manager of the new Municipality.(6) The Treasurer of the City of Arvida shall become Assistant-Manager of Administration of the new Municipality.(c) The Manager of the City of Kénogami shall become Assistant-Manager of Operations of the new Municipality.(ud, ouest, est et nord dudit lot 24-660 et son prolongement vers le nord-est jusqu'à l'intersection de la ligne centrale dc la rue Cabot.De là vers le sud-est suivant la ligne centrale de la rue Cabot jusqu'à son intersection avec la ligne centrale de la rue Roberval.De là vers le nord-est et le nord suivant la ligne centrale de la rue Roberval jusqu'àson intersection avec la ligne centrale de la rue Joliette.De là vers l'est jusqu'au coin sud-est du lot 25-43 du cadastre dc la cité d'Arvida.De là vers le nord-est suivant la ligne separative des lots 25-43 et 25-44 et son prolongement jusqu'à la ligne centrale de la rue Simonds) De là vers le sud suivant la ligne centrale de la rue Simonds jusqu'à son intersection avec la ligne centrale île la rue Drake.Thence southwesterly and following said dividing line between Ranges XII and XIII to its intersection with the dividing line between lots 9 and 10 in Range XIII of the Township of Laterrière.Thence northwesterly and following said dividing line between lots 9 and 10 to its intersection with the dividing line between the Townships of Jonquière and Laterrière.Thence southwesterly and following said dividing line between the Townships of Jonquière and Laterrière to its intersection with the south boundary of Range VII, Township of Jonquière.Thence westerly and following the south boundary of Range VII to its intersection with the dividing line between lots 32 and 33 in Range VII, Township of Jonquière.Thence northerly and following the dividing line between lots 32 and 33 to its intersection with the dividing line between Ranges VI and VII of the Township of Jonquière.Thence easterly and following the dividing line between Ranges VI and VII to its intersection with the dividing line between lots 35A and 36V in Range VI, Township of Jonquière.Thence northerly and following the dividing line between lots 35A and 36B in Range VI, the dividing line between lots 35B and 36 in Range V, the dividing line between lots 35 and 36B in Range IV to the starting point.Ward 7 All of that portion of territory comprised within the perimeter described hereinafter: Starting at the intersection of the median line of St-François Range Road with the dividing line between lots 35 and 36B Range IV, Township of Jonquière.Thence easterly and following the median line of St-François Range to its intersection with the median line of Mellon Boulevard.Thence northerly and following the median line of Mellon Boulevard to its intersection with the extension of the south boundary line of lot 24-660 on the cadastre for the City of Arvida.Thence following a broken line, that is, the south, west, east and north boundaries of said lot 24-660 and its extension in a northeasterly direction to the intersection of the median line of Cabot Street.Thence southeasterly and following the median line of Cabot Street to its intersection with the median line of Roberval Street.Thence northeasterly and northerly and following the median line of Roberval Street to its intersection with the median line of Joliette Street.Thence easterly to the southeast corner of lot 25-43 on the cadastre for the City of Arvida.Thence northeasterly and following the dividing line between lots 25-43 and 25-44 and its extension to the median line of Simonds Street.Thence southerly and following the median line of Simonds Street to its intersection with the median line of Drake Street. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, n\" 44 8313 De là vers l'est et le nord-est suivant la ligne centrale de la rue Drake jusqu'à son intersection avec la ligne centrale du boulevard Tachereau.De là vers l'est suivant la ligne centrale du boulevard Tachereau jusqu'à son intersection avec la limite ouest du rang XIII S.O.C.S.De là vers le nord suivant la limite ouest du rang XIII S.O.C.S.et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saguenay.Dc là vers l'ouest suivant la ligne médiane de la rivière Saguenay jusqu'à son intersection avec la ligne centrale de la route du pont d'Arvida.De là vers le sud-est suivant la ligne centrale de la route du pont d'Arvida jusqu'à son intersection avec la ligne centrale du boulevard Tachereau.De là vers l'ouest suivant la ligne centrale du boulevard Tachereau jusqu'à son intersection avec le prolongement de la limite est du lot 32 du rang III, canton de Jonquière.De là vers le sud suivant la dite limite est du lot 32 et son prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne centrale du chemin rang St-François.De là vers l'est suivant la ligne centrale du rang St-François jusqu'au point de commencement.Les quartiers ci-haut décrits sont montrés sur le plan A4-320 préparé par le soussigné en date du 20 juillet 1974.Daté à Kénogami, P.Q., le 20 juillet 1974 sous le numéro 805 de mes minutes.L'arpenteur-géomè/re, E.D.Chiasson.23 mots ont été rayés.60 mots ont été ajoutés en marge.Vraie copie de l'original portant le numéro 805 de mes minutes.L'arpenteur-géomètre, E.D.CllIASSON.Thence easterly and northeasterly and following the median line of Drake Street to its intersection with the median line of Tachereau Boulevard.Thence easterly and following the median line of Tachereau Boulevard to its intersection with the west boundary of Range XIII S.W.S.R.Thence northerly and following the west boundary of Range XIII S.W.S.R.and its extension to the median line of the Saguenay River.Thence westerly and following the median line of the Saguenay River to its intersection with the median line of the road to the Arvida Bridge; Thence southeasterly and following the median line of the road to the Arvida Bridge to its intersection with the median line of Tachereau Boulevard.Thence westerly and following the central line of Tachereau Boulevard to its intersection with the extension of the east boundary of lot 32 in Range III, Township of Jonquière.Thence southerly and following said east boundary of lot 32 and its extension to its intersection with the median line of St-François Range Road.Thence easterly and following the median line of St-François Range to the starting point.The wards hereinabove described are shown on plan A4-320 prepared by the undersigned and bearing date July 20, 1974.Given in Kénogani, P.Q., on July 20, 1974 under number 805 of my minutes.E.D.Chiasson, Land-surveyor.23 words have been deleted.60 words have been added in the margin.Certified true copy of the original bearing number 805 of my minutes.E.D.Chiasson, Land-surveyor. 8314_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, g novembre 1974, 106' année, n° 44 8315 Tout propriétaire ou tout locataire des municipalités concernées peut s'opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans les trente jours qui suivent la date de la dernière parution dans un journal du présent avis et peut faire connaître les motifs de son opposition en s'adressant par écrit à la Commission municipale du Québec, 680, rue St-Amable, Québec, G1A 1B3.On peut prendre connaissance et obtenir copie du texte de la requête conjointe en s'adressant à: Hôtel de Ville de Jonquière, 320 St-Dominique, Jonquière.Hôtel de Ville de Kénogami, 91 King George, Kénogami.Hôtel de Ville d'Arvida, 522 Place Davis, Arvida.Bureau de la paroisse Saint-Dominique-de-Jonquière, 149, St-Jean, Jonquière.Vraie copie.Le greffier de la Cité de Jonquière, 58899-0 Marcel Fortin.CLUB D'AUTO NEIGE CASTOR INC.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 6e jour de septembre 1974, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CLUB D'AUTO NEIGE CASTOR INC.», déjà constituée en corporation le ou vers le 3 décembre 1969, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de 850,000.Le siège social de la nouvelle corporation est à Larouche, district judiciaire de Chicoutimi.Le directeur du service des compagnies, Piprre Desjardins.58868-0 1355-4720 LES MONIALES REDEMPTORISTINES DE SAINTE-THERESE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des corporations religieuses, chapitre 75 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour de septembre 1974, constituant en corporation régie par la Loi des corporations religieuses, les membres actuels de « LES MONIALES REDEMPTORISTINES DE SAINTE-THERESE », déjà constituée en corporation le 24 août 1964 en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et possédei, est de $1,000,000.Le siège social de la corporation est à Sainte-Thérèse, district judiciaire de Terrebonne.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 3730-64 Any property-owner or tenant in the Municipalities concerned may object to the principle of amalgamation or to the terms and conditions of the joint petition, within the thirty days following the date of the last publication of the present notice in a newspaper, and may make known the reasons for his objection, in writing, to the Municipal Commission of Québec.680 Saint-Amable Street, Québec G1A 1B3.The text of the joint petition may be examined and a copy thereof may be obtained at the following places: City Hall of Jonquière, 320 Saint-Dominique, Jonquière.City Hall of Kénogami, 91 King George, Kénogami.City Hall of Arvida, 522 Place Davis, Arvida.Office of the Parish of Saint-Dominique-de-Jonquière, 149 Saint-Jean, Jonquière.Certified true copy.Marcel Fortin, 58899 Clerk of the City of Jonquière.CLUB D'AUTO NEIGE CASTOR INC.Notice is given that, under Part III of the Companies Act, letters patent, bearing date the 6th day of September, 1974, have been issued by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, incorporating as a corporation without share capital, the present members of \"CLUB D'AUTO NEIGE CASTOR INC.\".already incorporated on or about December 3, 1969, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, Chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $50,000.The head office of the new corporation is located in Larouche, Judicial District of Chicoutimi.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.58868-0 1355-4720 LES MONIALES REDEMPTORISTINES DE SAINTE-THERESE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, under the Religious Corporations Act, Statutes of 1971, Chapter 75, he has granted letters patent, dated the 9th day of September, 1974, conslituting as a corporation governed by the Religious Corporations Act, the present members of \"LES MONIALES REDEMPTORISTINES DE SAINTE-THERESE\", already incorporated on August 24, 1964, under Part III of the Companies Act.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav acquire and hold is to be limited, is $1,000,000.The head office of the corporation is located in Sainte-Thérèse, Judicial District of Terrebonne.Pierre Dfsjardins, Director of the Companies Service.58868 3730-64 8316 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Église Baptiste Évangclique dc Victoriaville Avis est donné que les soussignés Lucien Houle, Michel Bernier et Reginald Fauteux adresseront une requête au lieutenant-gouverneur en conseil de la province dc Québec pour demander la constitution en corporation de l'« Église Baptiste Évangélique de Victoriaville > en vertu des dispositions de la Loi de la constitution de certaines Églises, chapitre 305, statuts refondus dc la province de Québec, 1964, et amendements.Victoriaville, Québec, le 9 octobre 1974.Lucien Houle, Michel Bernier 5S699-42-4-0 & Reginald Fauteix.Église Baptiste Évangélique de Victoriaville Notice is given that the undersigned Lucien Houle, Michel Bernier and Reginald Fauteux will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for the incorporation of \"Église Baptiste Évangé.ique de Victoriaville\" under the provisions of the Church Incorporation Act, Chapter 305, Revised Statutes of Québec 1964, and its amendments.Victoriaville, Québec, October 9, 1974.Lucien Houle.Michel Bernier 58699-42-4 & Reginald Fauteux.Succession André Doyon Avis est par les présentes donné que Dame Alfred Doyon, née Marie-Claire Grondin, domiciliée au numéro civique 37, rue de l'Espinay, Québec, agissant en sa qualité de tutrice à ses deux enfants mineurs, savoir Lise et Johannc Doyon.nommée à cette fonction par jugement de la four Supérieure du district de Québec, rendu le 6 juin 1974 (dossier No 200-14-000396,744), a accepté sous bénéfice d'inventaire, aux termes d'un acte exécuté devant Me Claude Martel, notaire, 1191, 8ième Avenue, Québec 3, en date du 17 septembre 1974 et enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Québec, le 19 septembre 1974 sous le numéro 790.074, la part de ses enfants mineurs.Lise et Johannc Doyon, comme héritières légales de la succession de leur frère, André Doyon, en son vivant, mécanicien, domicilié au numéro civique 37, rue de l'Espinay, Québec, décédé le 8 mai 1974, sans laisser de testament.Un inventaire des biens du défunt a été fait devant Me Claude Martel, notaire, et peut être consulté à son bureau, aux heures d'affaires, à l'adresse ci-dessus.Après 2 mois du présent avis, ladite Dame Alfred Doyon, née Marie-Claire Grondin, paiera les créanciers à mesure qu'ils se présenteront, scion la loi.Donné à Québec, ce 24e jour de septembre, 1974.Le notaire, 58886-0 Claude Martel.LES IMMEUBLES AUTHIER LTEE Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, sous l'autorité de l'article 12 de la Loi des compagnies, donne avis qu'il a corrigé le 17 octobre 1974 les lettres patentes supplémentaires émises le 10 mai 1974.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-q 722056 Estate of André Doyon Notice is hereby given that Dame Alfred Doyon, maiden name Marie-Claire Grondin, residing at 37 De l'Espinay Street, Québec, acting in her capacity as tutrix to her minors children, Lise and Johanne Doyon, by Judgment of the Superior Court of the District of Québec, dated the sixth day of June, nineteen hundred and seventy-four (June 6th, 1974) (No.200-14-000396-744), has accepted under benefit of inventory under the terms of a deed executed before Me.Claude Martel, Notary, 1191, 8th Avenue, Québec, dated the seventeenth day of September, nineteen hundred and seventy-four (September 17th, 1974) and registered at the Québec Division Registry Office on the nineteenth day of September, nineteen hundred and seventy-four (September 19th, 1974) under number 790,074, the share of her minors childrens, Lise and Johanne Doyon, as legal heirs of the Estate of the late André Doyon, in his lifetime, mechanic, domiciled at 37 De l'Espinay Street, Québec, who died on the eighth day of May, nineteen hundred and seventy-four (May 8th, 1974) without having left a last wiil and testament.An inventory of the property of the deceased has been made before Me.Claude Martel, notary, and may be consulted at the office of the latter, at the address above indicated.After two (2) months of the present notice, the said Dame Alfred Doyon, maiden name Marie-Claire Grondin, will pay the creditors, according to law, they present themselves.Given at Québec, this 24th day of September, 1974.Claude Martel, 58886-0 Notary.LES IMMEUBLES AUTHIER LTEE The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, pursuant to section 12 of the Corn-pan iesAct, gives notice that he corrected, on October 17, 1974, the supplementary letters patent issued on May 10, 1974.Pierre Desjardins, Director oj the Companies Service.\u2022>M'^ 722056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8317 M ARCANA RESOURCES LIMITED (Non-Personal Liability) Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 24e jour d'avril 1974, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, le bureau principal dans la province de de Québec de «MARCANA RESOURCES LIMITED (Non-Personal Liability) », une compagnie minière dûment autorisée à vendre ou autrement aliéner, dans la province de Québec, ses actions, stocks, certificats d'actions, obligations et autres valeurs, a été transféré du numéro 80, rue Saint-Pierre, Québec, au numéro 800, d'Youville, suite 1700, Québec, district judiciaire de Québec.Monsieur Gilles de Billy, du numéro 800.d'Youville, suite 1700, Québec, demeure l'agent principal de ladite compagnie dans la province de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58907 PVA: 993-51 MARCANA RESOURCES LIMITED (Non-Personal Liability) Notice is given that, by new Power of Attorney, dated the 24th day of April, 1974, a copy of which has been transmitted to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the principal office in the Province of Québec of \"MARCANA RESOURCES LIMITED (Non-Personal Lability)\", a Mining Company duly authorized to sell or otherwise alienate in the Province of Québec, its shares, stock, stock-certificate, debentures and other securities, has been changed from 80 St.Peter Street, Québec to 800 D'Youville, suite 1700, Québec, judicial District of Québec.Mr.Gilles de Billy, of 800 D'Youville, suite 1700, Québec, remains the chief agent of the said company in the Province of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58907-o PVA: 993-51 Successions Danielle Bourdon Robert et Gilles Robert Par les présentes, prenez avis que conformément aux dispositions des articles 660 et suivants du Code civil de la province de Québec, les héritiers des successions Danielle Bourdon Robert et Gilles Robert, ont accepté lesdites successions sous bénéfice d'inventaire, en vertu d'un acte d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, reçu le 25 mars 1974, devant Me Pierre Girardot, notaire, et dont copie est enregistrée au bureau d'enregistrement de Shefford, sous le numéro 214632.Fait et donné à Granby, Que., ce 20 septembre 1974.221.rue Principale, Granby, Que.Le notaire, Pierre Girardot.58885-q Estates of Danielle Bourdon Robert and Gilles Robert Notice is hereby given that pursuant to the provisions of articles 660 and following of the Civil Code of the Province of Québec, the heirs of the estates of Danielle Bourdon Robert and Gilles Robert, have accepted the said estates under benefit of inventory, pursuant to a deed of acceptance of estate under benefit of inventory executed on March 25, 1974 before Me Pierre Girardot, notary, a copy of which is registered at the Shefford Registry Office under number 214632.Dated and given in Granby, P.Q., this 20th day of September, 1974.Pierre Girardot, Notary.221 Principale Street, Granby, P.Q.58885 Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Applications Act Laurie Earl Ferris Avis est donné qu'une requête sera présentée au ministre de la justice par Laurie Earl Ferris, résidant au 298, rue High, Sherbrooke, Québec, afin d'obtenir un décret du ministre de la justice lui permettant de changer son nom en celui de Laurie Earl Colborne, le tout conformément avec la Loi du changement de nom (S.Q., 1965, Ch.77).Ledit décret n'affectera nulle autre personne que le requérant.Le procureur du requérant, 58825-43-2-0 Harry E.Grundy, c.r.Laurie Earl Ferris Notice is hereby given by Laurie Earl Ferris, 298 High Street, Sherbrooke, Québec, that he intends to apply to the Minister of Justice, for the purpose of obtaining an order changing his name to Laurie Earl Colborne, the whole in conformity with the Change of Name Act (S.Q., 1965, Ch.77).The said decree will affect no person other than the applicant.Harry E.Grundy, q.c, 58825-43-2-0 Attorney for Applicant. SSI S QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106.No.44 Joseph Louis Mnrie Cauchon Avis est par les présentes donné que Joseph Louis Marie Cauchon, agent de probation au Gouvernement Provincial, domicilié à 111, rue La joie, St-Thomas-d'Aquin, comté de St-Hyacinthe, district de St-Hyacinthe, connu sous le nom de Louis Marie Cauchon, demandera au lieutenant-gouverneur de la province de Québec la pern-ission de changer son nom en celui de Joseph Louis Marie Laverdière.Ledit changement concernera également son épouse.Marie-Andrée Lussier et ses enfants, Jean-François Cauchon et Amélie Cauchon.St-Hyacinthe, ce 24 septembre 1974.Le procureur du requérant, 58788-43-2-0 Yvan Dupuis.Joseph Louis Marie Cauchon Notice is hereby given that Joseph Louis Marie Cauchon, probation officer, Provincial Government, domiciled at 111 Lajoie Street, St.Thomas-d'Aquin, County of St.Hyacinthe, District of St.Hyacinthe, known under the name of Louis Marie Cauchon.will ask the Lieutenant-Governor of the Province of Québec for the permission to change his name to that of Joseph I.mu:- Marie Laverdière.Said change will also affect his wife, Marie-Andrée Lussier, and children, Jean-François Cauchon and Amélie Cauchon.St.Hyacinthe, this 24th day of September, 1974.Yvan Dupuis, 58788-43-2-0 Attorney for the Applicant.Joseph Gabriel Jacques Paré Avis est donné que M.Joseph Gabriel Jacques Paré présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil, dans le but de changer son prénom en celui dc Louis Alexandre Paré, gardant comme prénom usuel celui de Louis.58790-43-2-o Louis Paré.Joseph Gabriel Jacques Paré Notice is given that Mr Joseph Gabriel Jacques Paré will apply to the Lieutenant-Governor in Council in order to change his christian name to that of Louis Alexandre, retaining Louis as his usual christian name.58790-43-2 Louis Paré.Stanislaus Raduinski Avis est par les présentes donné que Stanislaus Rad-winski présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d un décret lui permettant de changer son nom en celui de Stanley Joseph Rodden.Ce changement bénéficiera aussi à sa femme Irene Kathleen Sloman et sa fille mineure Briony Gail, tous résidant au 4740, avenue Linton, app.10, Montréal.Québec.Montréal, le 8 octobre 1974.Les procureurs du requérant, 58791-43-2-0 Rosf.niiek & Maciilovitch.Stanislaus Radwinski Notice is hereby given that Stanislaus Radwinski shall apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Stanley Joseph Rodden, to benefit as well his wife Irene Kathleen Sloman and his minor daughter Briony Gail, all residing at 4740 Linton Avenue, Apt.10.Montreal, Québec.Montreal, October 8, 1974.ROSF.NHEK & MaCHLOVITCH, 5S791-43-2-0 Attorneys for the Applicant.Joseph Roger Jean Claude Joseph Roger Jean Claude, gentilhomme, domicilié et résidant au numéro 1975 ouest, boul.de Maisonneuve, app.2001.dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Claude Côté.Montréal, ce 10e jour d'octobre 1974.58789-43-2-0 Bernard Sepinwall, avocat.Klaus Hans Gcorg Schroeder Avis est donné que Klaus Hans Georg Schroeder, homme d'affaires, résidant et domicilié au 74, avenue Bruce, cité de Westmount, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Peter William Broeker Les procureurs du requérant, Laing, Weldon, Courtois, Clarkson.58792-43-2-q Parsons, Gonthier & Tétreault.Joseph Roger Jean Claude Joseph Roger Jean Claude, gentleman, of the City and District of Montreal, therein residing and domiciled at 1975 de Maisonneuve Blvd.West, Apt.2001, will aPP'.v to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Claude Côté.Montreal, this 10th day of October, 1974.58789-43-2-0 Bernard Sepinwall, Attorney.Klaus Hans Gcorg Schroeder Take notice that Klaus Hans Georg Schroeder, businessman, domiciled in the District of Montreal nt 74 Bruce Avenue, in the City of Westmount, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order to change his name to Peter William Broeker.Laing, Weldon, Courtois, Clarkson, Parsons, Gonthier, & Tetrault, 58792-43-2-q Attorneys for the Petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre 1974, 106' année, n° 44 8319 Marie Joseph Estelle Clotilde Simard Prenez avis que Marie Joseph Estelle Clotilde Simard, secrétaire, domiciliée et résidant au 732, rue Principale à Granby, district de Bedford, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil la permission de changer son nom pour celui de Nicole Gibeault.Les procureurs de la requérante.Marquis.Jutras, Guertin 58826-43-2-q f.t Beaudry.Salim (Salomon) Thouma Sheito et als.Avis est donné par la présente que les personnes suivantes s'adresseront au ministre de la justice: 1.Salim (Salomon) Thouma Sheito: 2.Joseph Elias Thomas Sheito; 3.Marie Thérèse Sheito; 4.Joseph Marie Christophe Charles Sheito; 5.Marie Reine Elizabeth Danielle Sheito: 6.Joseph Marie Jude Stéphane Sheito; 7.Anne Marie Josée Sheito; toutes résidant au 10630, rue Berri, Montréal; 8.Joseph Georges Robert Sheito, résidant au 64A.rue Daniel, Châteauguay; 9.Joseph Antoine Thomas Sheito, résidant au 8465, rue Bretagne, St-Léonard; 10.Joseph Noël Albert Sheito; résidant au 2584, rue Désautels, Montréal; 11.Joseph Jean Jacques Sheito, résidant au 239, boul.Deguire, appartement 416, Ville St-Laurent; 12.Joseph Marie Victor Sheito, résidant au 5637, rue Terrebonne.Montréal; afin de changer leurs noms pour ceux respectifs de: Salim (Salomon) Thouma Sheitoyan.ce changement bénéficiant aussi à son épouse Claire Cattouf et à leur fils mineur Marie Joseph Jude Pierre Sheito, tous trois résidant au 10630, rue Berri, Montréal; Joseph Elias Thomas Salomon Sheitoyan; Marie-Thérèse Terry Sheitoyan ; Joseph Marie Christophe Charles Sheitoyan; Marie Reine Elizabeth Danielle Sheitoyan; Joseph Marie Jude Stéphane Sheitoyan; Anne Marie Josée Sheitoyan; Joseph Georges Robert Sheitoyan, ce changement bénéficiant aussi à son épouse Lorraine Laliberté, résidant au 64A, rue Daniel, Châteauguay; Joseph Antoine Thomas Sheitoyan.ce changement bénéficiant aussi à son épouse Diane Celsi.et à leur fils mineur Richard Joseph Benoit Sheito, tous trois résidant au 8465, rue Bretagne, St-Léonard; Joseph Noël Albert Sheitoyan, ce changement bénéficiant aussi à son fils mineur Joseph Robert André Sheito, résidant au 2584, rue Désautels, Montréal; Joseph Jean Jacques Sheitoyan; Joseph Marie Victor Sheitoyan, ce changement bénéficiant aussi à son épouse Louise Duguay, résidant au 5637, rue Terrebonne, Montréal.Le 15 octobre 1974.Les procureurs des requérants, 58827-43-2-0 Bernard, Girard & Despatis.Marie Joseph Estelle Clotilde Simard Notice is hereby given that Marie Joseph Estelle Clotilde Simard, secretary, domiciled and residing at 732 Principal Street, at Granby, District of Bedford, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to Nicole Gibeaull.Marquis, Jutras, Gufrtin ft Beaudry, 58826-43-2-0 Attorneys for the applicant.Salim (Salomon) Thouma Sheito et als.Notice is hereby given that the following persons shall apply to the Minister of Justice: 1.Salim (Salomon) Thouma Sheito; 2.Joseph Elias Thomas Sheito; 3.Marie Thérèse Sheito; 4.Joseph Marie Christophe Charles Sheito; 5.Marie Reine Elizabeth Danielle Sheito; 6.Joseph Marie Jude Stéphane Sheito; 7.Anne Marie Josée Sheito; all residing at 10630, Berri Street, Montreal; 8.Joseph Georges Robert Sheito, residing at 64A Daniel Street, Châteauguay; 9.Joseph Antoine Thomas Sheito, residing at 8465 Bretagne Street, St-Léonard; 10.Joseph Noël Albert Sheito, residing at 2584 Dcsaulels Street, Montreal; 11.Joseph Jean Jacques Sheito, residing at 239 Deguire Blvd., apt.416, City St-Laurent; 12.Joseph Marie Victor Sheito, residing at 5637, Terrebonne Street, Montreal; in order to change their names respectively to: Salim (Salomon) Thouma Sheitoyan, this change shall also benefit to his wife Claire Cattouf and to their minor son Marie Joseph Jude Pierre Sheito, all three residing at 10630 Berri Street, Montreal; Joseph Elias Thomas Salomon Sheitoyan; Marie Thérèse Terry Sheitoyan; Joseph Marie Christophe Charles Sheitoyan; Marie Reine Elizabeth Danielle Sheitoyan; Joseph Marie Jude Stéphane Sheitoyan; Anne Marie Josée Sheitoyan; Joseph Georges Robert Sheitoyan, this change shall also benefit to his wife Lorraine Laliberté.residing at 64A Daniel Street, Châteauguay; Joseph Antoine Thomas Sheitoyan, this change shall also benefit to his wife Diane Celsi and to their minor son Richard Joseph Benoit Sheito, all three residing at 8465 Bretagne Street, St-Léonard; Joseph Noël Albert Sheitoyan, this change shall also henefit to his minor son Joseph Robert André Sheito, residing at 2584 Desautels Street, Montreal; Joseph Jean Jacques Sheitoyan; Joseph Marie Victor Sheitoyan, this change will also benefit to his wife Louise Duguay, residing at 5637 Terrebonne Street, Montreal.October 15, 1974.Bernard, Girard & Despatis, 58827-43-2-o Attorneys for the Petitioners. 8320 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 Raynald Cauchon (Paré) Prenez avis que monsieur Raynald Cauchon (Paré) a présenté une requête à l'honorable ministre de la justice du Québec, pour faire changer son nom en celui dc Raynald Paré, conformément au chapitre 77 des Lois de 1965.Les procureurs du requérant.Let arte, Bouchard, Cartier 58883-44-2-0 & Caron, avocats.Raynald Cauchon (Paré) Notice is given that Raynald Cauchon (Paré) has presented a request to the Honourable Minister of Justice of Québec to change his name to that of Raynald Paré, in conformity with chapter 77 of the Statutes of 1965.Letarte, Bouchard, Cartier & Caron, lawyers, 58883-44-2 Attorneys for the applicant.Pamméla Paquet Nous donnons avis que Pamméla Paquet, aide-infirmière à l'Hôpital Notre-Dame-de-Lourdes, domiciliée au 4435, Adam dans les cité et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de Carmen Paquette.Les procureurs de la requérante, 58884-44-2-0 Tru del, Larivière et Toulet.Pamméla Paquet Notice is hereby given that Pamméla Paquet, assistant-nurse at Notre-Dame-de-Lourdes Hospital, domiciled at 4435 Adam in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing her name to Carmen Paquette.Trudel, Larivière et Toulet, 58884-44-2-0 Attorneys for the petitioner.Jean-Claude Drain Avis est par les présentes donné que Jean-Claude Drain, résidant et domicilié au 4615, Léger, app.405, Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Johannes Drayan.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Le requérant, 58900-44-2-o Jean-Claide Drain.Jean-Claude Drain Notice is hereby given that Jean-Claude Drain, residing at 4615 Léger, Apt.405, Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to Johannes Drayan.This change will not affect any person else than the applicant.58900-44-2-o Jean-Claude Drain, Petitioner.Compagnies étrangères siège social Extra-Provincial Companies head office BOSTON FACTORS INTERNATIONAL, INC.Avis est donné qu'en vertu d'une nouvelle procuration en date du 23e jour de septembre 1974, dont copie a été remise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, le bureau principal dans la province de Québec de « BOSTON FACTORS INTERNATIONAL, INC.», une compagnie dûment autorisée à exercer son commerce dans ladite province, en vertu de la Loi des compagnies étrangères, a été transféré du numéro 1, place Ville-Marie, suite 750, Montréal, au numéro 615, boulevard Dorchester ouest, suite 900, Montréal, district judiciaire de Montréal.Monsieur Douglas H.Tees, avocat, du numéro 1, Çlace Ville-Marie, Édifice de la Banque Royale, suite 00, Montreal, demeure l'agent principal de ladite compagnie dans la province de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58905 PS: 18-73 BOSTON FACTORS INTERNATIONAL, INC.Notice is given that, by new Power of Attorney, dated the 23rd day of September, 1974, a copy of which has been transmitted to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the principal office in the Province of Québec of \"BOSTON FACTORS INTERNATIONAL, INC.\", a company duly authorized to carry on business in the said Province in virtue of the Extra-Provincial Companies Act, has been changed from Suite 750, 1 Place Ville-Marie, Montreal to Suite 900, 615 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal, Mr.Douglas H.Tees, advocate, of Suite 700, The Royal Bank Building, 1 Place Ville-Marie, Montreal, remains the chief agent of the said company in the Province of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58905-O PS: 18-73 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre i974.106' année, n\" U 8321 Divers Compagnie Miscellaneous Company SIIUFELT, BERRIOGE & COMPANY LIMITED SIIUFELT, BKRRIDGE & COMPANY LIMITED En conformité avec l'article 90 de la Loi des compagnies, avis est donné que les administrateurs de « SHUFELT, BERRIDGE & COMPANY LIMITED » ont, le 6 septembre 1974 édicté le règlement spécial « A » décrétant que les actifs de la compagnie seront distribués entre les actionnaires au prorata de leurs intérêts dans les 15 jours de la publication du présent avis dans la Gazette officielle de Québec.Montréal, le 30 septembre 1974.Les procureurs de la compagnie.Monceau, Simard, Hébert & Héroux.31, rue Saint-Jacques, suite 300.Montréal, Que.58904-o Pursuant to the provisions of section 90 of the Companies Act.notice is hereby given that the directors of \"SHUFELT, BERRIDGE & COMPANY LIMITED\" have, on September 6th, 1974, enacted special by-law \"A\" providing for the distribution of the assets of the company rateably among its shareholders 15 days following the publication of the present notice in the Québec Official Gazelle.Montreal, September 30th, 1974.Monceau, Simard, Hébert & Héroux, Attorneys for the company.31 St.James Street, Suite 300, Montreal, Que.58904-o Demandes à la Législature Applications to Legislature Succession Sir Joseph David Rodolphe Forget Avis est, par les présentes, donné que Jacques Na-deau, Roger Ouimet.Jacques Roy, Joseph Patrick Clément Gauthier et Guy Poliquin des ville et district de Montréal, agissant en leur qualité d'exécuteurs testamentaires de la Succession Joseph David Rodolphe Forget s'adresseront à l'Assemblée Nationale du Québec pour l'adoption d'une loi aux fins d'avancer la date du partage et d'accélérer la remise des biens compris dans ladite succession aux légataires de feu Sir Joseph David Rodolphe Forget conformément aux dispositions testamentaires de ce dernier.Montréal, le 9 octobre 1974.Les procureurs des requérants, McLean, Marler, Tees, Watson, Poitevin, 58758-42-4-0 Javft & Roberge.La Cité de westmount La Cité de Westmount demandera à l'Assemblée nationale, au cours de sa prochaine session, d'adopter une loi confirmant le titre qu'elle a acquis par expropriation aux lots Nos 380-18 et 380-60 du cadastre officiel de la paroisse de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, situés entre le boulevard Dorchester, l'avenue Gladstone, la rue Tupper et l'avenue Atwaler, à Westmount, et convertissant en un droit personnel à une indemnité appropriée tout droit de propriété ou autre droit réel dans ou sur lesdits lots qu'on aurait pu faire valoir sans cette loi.Québec, ce 10e jour d'octobre 1974.Les procureurs de la Cité de Westmount.létourneau, stein, marseille, \u20228819-43-4-0 Delisle & Larue.Estate of Sir Joseph David Rodolphe Forget Notice is hereby given that Jacques Nadeau, Roger Ouimet, Jacques Roy, Joseph Patrick Clément Gauthier and Guy Poliquin of the City and District of Montreal, in their quality of testamentary executors of the Estate Sir Joseph David Rodolphe Forget, shall apply to the Québec National Assembly, for the adoption of an Act, in order that it be proceeded earlier to the partition of the assets comprised in the said Estate, as well as to accelerate the distribution of such assets to the legatees of Sir Joseph David Rodolphe Forget, in conformity with his testamentary dispositions.Montreal, October 9th, 1974.McLean, Marler, Tees, Watson, Poitevin, Javft & Robf.rge, 58758-42-4-0 Attorneys for the Petitioners.The City of Westmount The City of Westmount will apply to the National Assembly at its next session for an act confirming the title it has acquired through expropriation to lots Nos.380-18 and 380-66 of the official cadastre of the Parish of Montreal, registration division of Montreal, situated between Dorchester Boulevard, Gladstone Avenue, Tupper Street and Atwater Avenue, in Westmount, and converting into a personal right to an appropriate indemnity any right of ownership or other real right in or to the said lots that might have been asserted but for such act.Québec City, October 10, 1974.létourneau, stein, marseille, Delisle & Larue, 58819-43-4-0 Attorneys for the City of Westmount. 8322 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, November 2, 7974.Vol.106, No.U .Succession Charles Séraphin Rodier Les exécuteurs testamentaires de Che.rles Séraphin Rodier demanderont à l'Assemblée nationale, au cours de sa prochaine session, d'adopter une loi interdisant de provoquer avant le 2 avril 1980 le partage des biens de la succession et prolongeant leur mandat jusqu'au règlement définitif de celle-ci.Québec, ce 1er octobre 1974.Les procureurs de la pétitionnaire, létourneau, stein, marseille, 58648-41-4-0 Delisle & I.ahue.Curatelle publique Succession Herménégilde Rrimraii Succession de Bruneau, Herménégilde, en son vivant de 4266, rue Marquette, Montréal.Québec, décédé le 30 mars 1970.Sous l'empire de la I-oi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession cl la preuve de toute réclamation CODtTC elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2N 1X6 58871-o Succession Joseph Emile Fournicr Succession de Fournier, Joseph Emile, en son vivant de 7766.De Gaspé, Montréal, Québec, décédé le 17 février 1974.Sous l'empire dc la Loi dc la curatelle publique (I.Q.1971, c'iap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurenl.Montréal 354, H2X 1X6 58872-0 Succession Jules Malet Succession de Malet, Jules, en son vivant de 355, boul.l'Ange Ge.rdicn, L'Assomption, P.Q., décédé le 8 octobre 1968.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve dc toute réclamation contre elle.Le Cuhateuh public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2X 1X6 58873-0 Estate of Charles Séraphin Rodier The testamentary executors of Charles Séraphin Rodier will apply to the National Assembly, at its next session, for an act prohibiting any demand for the partition of the property of the estate until April 2, 1980 and extending their term of office until the final settlement of the estate.Québec, this 1st day of October 1974.létourneau, stein, marseille, Delisle & Larue, 58648-41-4-0 Attorneys for the Petitioner.Public Curatorship Estate of Herménégilde Bruneau Estate of the late Bruneau.Heiménégilde, in his lifetime of 4266 Marquette Street, Montreal, Québec, deceased Mardi 30.1970.I'ndcr tie authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and l.e \"ill receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St-Laurent Blvd.Montreal 354.H2N 1X6 5887 l-o Estate of Joseph Emile Fournier Estate of the late Fournier.Joseph Emile, in his lifetime of 7766 De Gaspé, Montreal, Québec, deceased February 17, 1974.The undersigned hereby gives notice that under the authority of tie Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2N 1X6 58872-0 Estate of Jules Malet Estate of the late Malet.Jules, in his lifetime of 365 l'Ange Gardien Blvd., L'Assomption, P.Q., deceased October 8.1968.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator ok Québec.9310 St-Laurent Blvd., Montreal 354, H2X 1X6 58873-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Z novembre 1974, 106' année, n° 44 8323 Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE DE L'AUVERGNE (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 21 janvier 1974 par « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-JEROME DE L'AUVERGNE », changeant son nom en celui de « LA CAISSE POPULAIRE DE L'AUVERGNE ».Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58906-o Albert Jessop.CAISSE D'EPARGNE ET D'ENTRAIDE ECONOMIQUE DE QUEBEC (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a apprduvé le règlement adopté le 10 septembre 1974 par la « CAISSE D'EPARGNE ET D'ENTRAIDE ECONOMIQUE DE QUEBEC » modifiant son territoire qui était « les districts électoraux de Limoilou.St-Sauveur, Chauveau, Louis-Hébert, Montmorency et Jean-Talon » en celui de « les districts électoraux de Limoilou.Vanier, Chauveau, Louis-Hébert, Montmorency, Jean-Talon et Lévis ».Québec, le 18 octobre 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58921-0 Albert Jessop.Syndicats professionnels ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'il a approuvé le règlement de « ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX », maintenant connu sous le nom de « SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.) », changeant son siège social de Clermont à La Malbaie, et ce, en vertu de l'article 2 de la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58868-0 SP: 3449-37 LA CAISSE POPULAIRE DE L'AUVERGNE (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies anil Cooperatives has approved the by-law adopted on January 21, 1974, bv \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-JEROME DE\" L'AUVERGNE\", changing its name to that of \"LA CAISSE POPULAIRE DE L'AUVERGNE\".Québec, October 16, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 58906 Companies and Cooperatives.CAISSE D'EPARGNE ET D'ENTRAIDE ECONOMIQUE DE QUEBEC (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on September 10, 1974, by the \"CAISSE D'EPARGNE ET D'ENTRAIDE ECONOMIQUE DE QUEBEC\", modifying its territory, which was \"the Electoral Districts of Limoilou, St-Sauveur, Chauveau, Louis-Hébert, Montmorency and Jean-Talon\" to that of: \"the Electoral Districts of Limoilou, Vanier, Chauveau, Louis-Hébert, Montmorency, Jean-Talon and Levis\".Québec, October 18.1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 58921 Companies and Cooperatives.Professional Syndicates ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that he has approved the bylaw of \"ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES DE CHARLEVOIX\", now known under the name of \"SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (S.T.E.C.)\".transferring its head office from Clermont to La Malbaie, the foregoing pursuant to section 2 of the Special Corporate Powers Act.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 SP: 3449-37 8324 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.November S.1974, Vol.106, No.44 SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE LA REGION DE MISSISQUOI ET DE L'ESTRIE (UPA) (Aoi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 24 septembre 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE LA REGION DE MISSISQUOI El DE L'ESTRIE il'PA) .avec sure social situé à Dunham, district judiciaire de Bedford.Ae sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert .Ifssop.58887-o SP: 1358-9676 FRATERNITE DES POLICIERS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL INC.(Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 25 septembre 1974, il a autorisé le changement de nom de « FRATERNITE DES POLICIERS DE MONTREAL INC.», dont la constitution a été autorisée le 12 mai 1950, avec siège social à Montréal, en celui de « FRATERNITE DES POLICIERS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL INC.», et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58888-0 SP: 1270-50 Ministère des Terres et Forêts Cadastre Canton de Belleau Cadastre officiel du canton de Belleau, municipalité de la paroisse de Saint-Mathieu, division d'enregistrement de Shawinigan.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 3B-2 du rang X est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 8 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Canton de Lctellicr Cadastre officiel du canton de Letellier, municipalité de la cité des Sept-Iles, division d'enregistrement de Sept-Iles.SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE LA REGION DE MISSISQUOI ET DE L'ESTRIE (UPA) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on September 24, 1974, he authorized the constitution of a professional syndicate under the name of \"SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE LA REGION DE MISSISQUOI ET DE L'ESTRIE (UPA)\", with its head office located in Dunham, Judidial Didstrict of Bedford.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58887 SP: 1358-9676 FRATERNITE DES POLICIERS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL INC.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on September 25, 1974, he authorized the change of name of \"FRATERNITE DES POLICIERS DE MONTREAL INC.\", whose incorporation was authorized on May 12, 1950, with its head office in Montreal, to \"FRATERNITE DES POLICIERS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL INC.\", the foregoing, pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jfssop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58888 SP: 1270-50 Department of Lands and Forests Cadastre Township of Belleau Official cadastre of the township of Belleau, municipality of the parish of Saint-Mathieu, registration division of Shawinigan.Notice is hereby given that a remaining part of lot 3B-2 of range X is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 8, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Township of Letellier Official cadastre of the township of Letellier, municipality of the city of Sept-Iles, registration division of Sept-Iles. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1971,, 106' année, nc U 8325 Avis est par la présente donné que les lots 2-A-8-2, 2-A-9-1-1, 2-A-9-4, 2-A-10-4, 2-A-10-5, 2-A-11-4 et une partie des lots 2-A-8 à 2-A-ll et 2-A-9-1 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 2 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalannb, a.-g.Canton dc Letellier Cadastre officiel du canton de Letellier, municipalité de la cité de Sept-Iles, division d'enregistrement de Sept-Iles.Avis est par la présente donné que les lots 38 à 53 du rang I est, sont ajoutés et que les lots 15-13 à 15-19 et une partie des lots 15-20 et 15 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Canton de Letellier Cadastre officiel du canton de Letellier, municipalité de la cité des Sept-Iles, division d'enregistrement de Sept-îles.Avis est par la présente donné que les lots 28 à 37 du rang I est, sont ajoutés et que les lots 15-47, 15-48 et qu'une partie du lot 15 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Municipalité de Pabos Cadastre officiel de la municipalité de Pabos, municipalité de la ville de Chandler et municipalité de Pabos, division d'enregistrement de Gaspé.Avis est par la présente donné que l'île « H » est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 24 septembre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-o Norman Lalanne, a.-g.Paroisse de Pointe-Claire Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, municipalité de la ville de Pointe-Claire, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 107-39 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Paroisse de Pointe-Claire Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire, municipalité de la cité de Beaconsfield, division d'enregistrement de Montréal.Notice is hereby given that lots 2-A-8-2, 2-A-9-1-1, 2-A-9-4, 2-A-10-4, 2-A-10-5, 2-A-l 1-4 and a part of lots 2-A-8 to 2-A-ll and 2-A-9-1 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 2nd, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Township of Letellier Official cadastre of the township of Letellier, municipality of the city of Sept-Iles, registration division of Sept-Iles.Notice is hereby given that lots 38 to 53 of range I east, are added and that lots 15-13 to 15-19 and a part of lots 15-20 and 15 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 4, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Township of Letellier Official cadastre of the township of Letellier, municipality of the city of Sept-Iles, registration division of Sept-Iles.Notice is hereby given that lots 28 to 37 of range I east, are added and that lots 15-47, 15-48 and that a part of lot 15 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 4, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Municipality of Pabos Official cadastre of the municipality of Pabos, municipality of the town of Chandler and the municipality of Pabos, registration division of Gaspé.Notice is hereby given that isle \"H\" is cancelled in virtue of article 2i74a of the Civil Code.Québec, September 24, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Parish of Pointe-Claire Official cadastre of the parish of Pointe-Claire, municipality of the town of Pointe-Claire, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 107-39 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 4, 1974.Norman Lalanne, a.-c., 58889-o For the Deputy Minister.Parish of Pointe-Claire Official cadastre of the parish of Pointe-Claire, municipality of the city of Beaconsfield, registration division of Montreal. 8326 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol, 106, No.44 Avis est par la présente donné que le lot 24-2-2 et une partie du lot 24-2 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 4 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-o Norman Lalanne, a.-g.Notice is hereby given that lot 24-2-2 and that a part of lot 24-2 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 4, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister Paroisse de Rivière-des-Prairies Cadastre officiel de la paroisse dc Rivière-des-Prairies, municipalité de la ville de Montréal, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 141-141-1 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 2 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-q Norman Lalanne, a.-g.Parish of Riviere-des-Prairies Official cadastre of the parish of Rivière-des-Prairies, municipality of the town of Montreal, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 141-141-1 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 2nd, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-o For the Deputy Minister.Village dc Roxton Falls Cadastre officiel du village de Roxton Falls, municipalité du village de Roxton Falls, division d'enregistrement de Shefford.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 5 à 7, 15 à 26, 33.34, 102F à 102L, 116, 130 à 133, 141 à 145, 346, 347, 352, 353, 409 à 418, 421, 422, 425, 426, 429 à 432, 441, 442, 452 à 455, 545 à 547, 551 et 562 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil et que les lots 566 à 635 sont ajoutés en vertu des articles 2174 et 2174a du Code civil et de l'article 7 de la Loi du cadastre (chap.320, S.R.1964).Québec, le 10 septembre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-o Norman Lalanne, a.-g.Village of Roxton Falls Official cadastre of the village of Roxton Falls, municipality of the village of Roxton Falls, registration division of Shefford.Notice is hereby given that a part of lots 5 to 7, 15 to 26, 33, 34, 102F to 102L, 116, 130 to 133, 141 to 145, 346, 347, 352, 353, 409 to 418, 421, 422, 425, 426, 429 to 432, 441, 442, 452 to 455, 545 to 547, 551 and 562 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code and that lots 566 to 635 are added in virtue of articles 2174 and 2174a of the Civil Code and of article 7 of the Cadastre Act (chap.320, S.R.1964.) Québec, September 10, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Jean-Chrysostome Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Chrysos-tome, municipalité de la ville de Saint-Jean-Chry-sostome, division d'enregistrement de Lévis.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 39-2 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 9 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Parish of Saint-Jean-Chrysostome Official cadastre of the parish of Saint-Jean-Chrysostome, municipality of the town of Saint-Jean-Chrysostome, registration division of Levis.Notice is hereby given that a part of lot 39-2 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 9, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Maurice Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Maurice, municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-France, division d'enregistrement de Champlain.Avis est par la présente donné que les lots 272-7 à 272-10 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 3 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-0 Norman Lalanne, a.-g.Parish of Saint-Maurice Official cadastre of the parish of Saint-Maurice, municipality of the parish of Saint-Louis-de-France, registration division of Champlain.Notice is hereby given that lots 272-7 to 272-10 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, October 3, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-0 For the Deputy Minister. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106- année, no 44 8327 Paroisse de Saint-Sauveur Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, municipalité de Piedmont*, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que la partie restante des lots 27-44 et 27-47 est annulée en vertu dc l'article 2174a du Code civil.Québec, le 16 septembre 1974.Pour le sous-ministre, 58889-o Norman Lalanne, a.-o.Parish of Saint-Sauveur Official cadastre of the parish of Saint-Sauveur, municipality of Piedmont*, regisrration division of Terrebonne.Notice is hereby given that a remaining part of lots 27-44 and 27-47 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, September 16, 1974.Norman Lalanne, a.-g., 58889-o For the Deputy Minister.Régie des Marchés agricoles du Québec Québec Agricultural Marketing Board L'Office des producteurs de lait fournisseurs au poste de réception et de transformation d'Henryville de la compagnie Elmhurst Dairy Ltd.Avis est par les présentes donné que, conformément û à l'article 108 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, P.L.12) et suivant sa décision numéro 1731 du 17 octobre 1974, la Régie des marchés agricoles du Québec dissout l'Office des producteurs de lait fournisseurs au poste de réception et de transformation d'Henryville de la compagnie Elmhurst Dairy Ltd.Montréal, ce 22 octobre 1974.58909-O Le secrétaire adjoint, Claude Régnier.L'Office des producteur» de lait fournisseurs au poste de réception et de transformation d'Henryville dc la compagnie Elmhurst Dairy Ltd.Notice is hereby given that, pursuant to section 108 of the Farm Products Marketing Act (1974, Bill 12) and in conformity with its decision number 1731 dated October 17, 1974, the Québec Agricultural Marketing Board dissolves the \"Office des producteurs de lait fournisseurs au poste de réception et de transformation d'Henryville de la compagnie Elmhurst Dairy Ltd.\" Montreal.October 22, 1974.ïVII Ml Claude Régnier, Assistant Secretary.L'Office des producteurs de lait dc la région de Sorel Conformément à l'article 108 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, P.L.12) et conformément à sa décision numéro 1728 du 17 octobre 1974, la Régie des marchés agricoles du Québec donne avis dc la dissolution de l'Office des producteurs de lait de la région de Sorel.Montréal, le 22 octobre 1974.59809-O Le secrétaire adjoint, Claude Régnier.L'Office des producteurs de lait de la région de Sorel Pursuant to section 108 of the Farm Products Marketing Act (1974, Bill 12) and in conformity with its decision number 1728 dated October 17, 1974, the Québec Agricultural Marketing Board gives notice of the dissolution of the \"Office des producteurs de lait de la région de Sorel\".Montreal.October 22, 1974.58909 Claude Régnier, Assistant Secretary.L'Office des producteurs de lait à la laiterie Magog inc.Avis est par les présentes donné que, conformément à l'article 108 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (1974, P.L.12) et suivant sa décision numéro 1730 du 17 octobre 1974, la Régie des marchés agricoles du Québec dissout l'Office des producteurs de lait à la laiterie Magog Inc.Montréal, ce 22 octobre 1974.58909-u Le secrétaire adjoint, Claude Régnier.L'Office des producteurs de lait à la laiterie Magog inc.Notice is hereby given that, pursuant to section 108 of the Farm Products Marketing Act (1974, Bill 12) and in conformity with, its decision number 1730 dated October 17, 1974, the Québec Agricultural Marketing Board dissolves the \"Office des producteurs de lait à la laiterie Magog Inc.\".Montreal, October 22, 1974.5S909 Claude Régnier, Assistant Secretary. 8328 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 L'Office des producteurs dc lait de la laiterie Shawinigan Limitée Avis est par les présentes donné que, conformément à l'article 108 de la Loi sur la mise en maicb.é des produits agricoles (1974, P.L.12) et suivant sa décision numéro 1732 du 17 octobre 1974, la Régie des marchés agricoles du Québec dissout l'Office des producteurs de lait de la laiterie Shawinigan Limitée.Montréal, ce 22 octobre 1974.Le secrétaire adjoint, 58909-o Claude Régnieu.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur L'Office des producteurs de lait de la laiterie Shawinigan Limitée Xotice is given that, pursuant to section 108 of the Farm Products Marketing Act (1974, Bill 12) and in conformity with its decision number 1732 dated October 17, 1974, the Québec Agricultural Marketing Board dissolves the \"Office des producteurs de lait de la laiterie Shawinigan Limitée.\" Montreal, October 22, 1974.Claude Régnier, 58909 Assistant Secretary.Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les services dc santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971.il a accordé des lettres patentes supplémentaires en date du 25e jour de septembre à la corporation « HOPITAL YOUVILLE DE NORANDA ».changeant son nom en celui de « CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA ».Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetley.58868-0 SS: 45-73 CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 41 of the Health services and social services Act, Chapter 48 of the Statutes of 1971, he granted supplementary letters patent dated September 25, 1974 to \"HOPITAL YOUVILLE DE NORANDA\", changing its name lo that of \"CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA\".William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 SS: 45-73 Sociétés coopératives agricoles Cooperative Agricultural Associations SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES BOIS-FRANCS (fyoi des sociétés coopératives agricoles) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la requête des sociétés coopératives agricoles « MEUNERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VICTORIAVILLE » et «SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE WARWICK », datée du 22 octobre 1974, demandant la confirmation dc l'acte d'accord prévoyant la fusion de ces deux sociétés coopératives agricoles.Le nom dc la coopérative résultant de cette fusion est « SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES BOIS-FRANCS».Le siège social dc cette société coopérative agricole est situé à Victoriaville, Québec, dans le district électoral d'Arthabaska.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 58928-0 Albert Jessop.SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES BOIS-FRANCS (Cooperative Agricultural Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the petition of the cooperative agricultural associations \"MEUNERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE VICTORIAVILLE\" and \"SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE WARWICK\", dated October 22, 1974, requesting the confirmation of a deed of agreement providing for the amalgamation of these two cooperative agricultural associations.The name of the association resulting from this amalgamation is \"SOCIETE COOPERATIVE AGRI-COLE DES BOIS-FRANCS\".The head office of this cooperative agricultural association is located in Victoriaville, Québec, in the Electoral District of Arthabaska.58928 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, no 44 8329 Société d'habitation du Québec Québec Housing Corporation Cité de Thetford Mines (Modifications) Avis est donné qu'en vertu de l'article 40 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (L.Q., 1966/1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté en conseil numéro 3569-74 en date du 9 octobre 1974, ratifié les modifications adoptées par le règlement numéro 946 en date du 3 juin 1974 dc la cité de Thetford Mines à son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée « Secteurs Saint-Maurice, Mitchell et Smith », décrétée « zone de rénovation » par l'arrêté en conseil numéro 2886 en date du 24 septembre 1969.La Société d'habitation du Québec a, par sa résolution numéro 7804 en date du 18 septembre 1974, approuvé ces modifications.Le secrétaire, 58908-o Jean-Luc Lesage, notaire.Cité de Joliette (Modifications) Avis est donné qu'en vertu de l'article 40 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (L.Q.1966/1967, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté en conseil numéro 3149-74 en date du 28 août 1974, ratifié les modifications adoptées par le règlement numéro 729-E en date du 22 avril 1974 de la citéde Joliette à son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée « Centre-Ville », décrétée « zone de rénovation » par l'arrêté en conseil numéro 1167-73 en date du 21 mars 1973 et par l'arrêté en conseil numéro 3579-74 en date du 9 octobre 1974 décrété « zone de rénovation » le territoire additionnel qui fait l'objet de ce programme.La Société d'habitation du Québec a, par sa résolution numéro 7740 en date du 19 août 1974, approuvé ces modifications.Le secrétaire, 58908-o Jean-Luc Lesage, notaire.City of Thetford Mines (Modifications) Notice is hereby given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1966/1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor in Council has, by Order number 3569-74 dated October 9, 1974, ratified the modifications adopted by by-law number 946 dated June 3, 1974 of the City of Thetford Mines in its renewal program for the part of its territory known as \"Secteurs Saint-Maurice, Mitchell and Smith\", declared a \"renewal zone\" by Order number 2886 dated September 24, 1969.The Québec Housing Corporation has, by its resolution number 7804 dated September 18, 1974 approved these modifications.Jean-Luc Lesage, Notary, 58908-o Secretary.City of Joliette (Modifications) Notice is hereby given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1966/1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor in Council has, by Order number 3149-74 dated August 28, 1974, ratified the modifications adopted by by-law number 729-E dated April 22, 1974 of the City of Joliette in its renewal program for the part of its territory known as \"Centre-Ville\", declared a \"renewal zone\" by Order number 1167-73 dated March 28.1973 and by Order number 3579-74 dated October 9, 1974, declared a \"renewal zone\" the additional part of its territory covered by the program.The Québec Housing Corporation has, by its resolution number 7740 dated August 19, 1974 approved these modifications.Jean-Luc Lesage, Notary, 58908-o Secretary.Ministère des Richesses naturelles Department of Natural Resources Révocation de concessions minières inexploitées Prenez avis qu'en vertu d'un décret du ministre des richesses naturelles signé le 13 septembre 1974, les concessions minières ci-après énumérées ont été révoquées, savoir: La concession minière numéro 19, patentée le 6 septembre 1929, couvrant la demie sud des lots quarante et un (Yi S.lot 41) et quarante-deux (J-£ S.lot 42) du Revocation o/ unoperated mining concessions Notice is given that, pursuant to an order of the Minister of Natural Resources, signed on September 13, 1974, the mining concessions hereinafter listed have been revoked, namely: Mining concession number 19, for which letters patent were issued on September 6, 1929, covering the southerly half of lots forty-one (S.3^ lot 41) and forty- 8330 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol.106, No.44 rang un (1) du cadastre officiel du canton de Hampden dans le district électoral de Mégantic-Compton, (114 acres); La concession minière numéro 236, patentée le 5 mars 1929, couvrant les blocs six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15) du cadastre officiel du canton de Bousquet, dans le district électoral de Rouyn-Noranda, (621 acres); La concession minière numéro 313, émise le 18 novembre 1940, mais non patentée, couvrant le quart nord-est du lot quatorze N.E.lot 14) du rang onze (XI) du cadastre officiel du canton de Buckingham, district électoral de Papineau, (50 acres); La concession minière numéro 334, patentée le 2 mai 1955, couvrant la demie nord du lot treize (J/£ N.lot 13) du rang un (I) du cadastre officiel du canton de Derry, district électoral dc Papineau, (50 acres) ; La concession minière numéro 396, patentée le 4 mai 1957, couvrant le lot vingt-sept (27) du rang quatre (IV) du cadastre officiel du canton de Lynch, district électoral de Laurentide-Labelle, (105.43 acres); Le présent avis est publié en conformité avec l'article 209 de la Loi des mines (1965, 1ère session, chapitre 34 et modifications).Signé à Québec, le 21 octobre 1974.Le sous-ministre.58927-o J.-G.Fredette.two (S.14 lot 42) in Range One (I) on the official cadastre for the Township of Hampden in the Electoral District of Mégantic-Compton, (114 acres); Mining concession number 236, for which letters patent were issued on March 5.1929, covering blocks six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen and fifteen (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15) on the official cadastre for the Township of Bousquet, in the Electoral District of Rouyn-Noranda, (621 acres); Mining concession number 313, granted on November 18, 1940, but not patented, covering the northeasterly quarter of lot fourteen (N.E.% lot 14) in Range\" Eleven (XI) on the official cadastre for the Township of Buckingham, in the Electoial District of Papineau, (50 acres) ; Mining concession number 334, for which letters patent were issued on May 2, 1955, covering the northerly half of lot thirteen (N.Yt lot 13) in Range One (I) on the official cadastre for the Township of Derry, in the Electoral District of Papineau, (50 acres); Mining concession number 396.for which letters patent were issued on May 4.1957, covering lot twenty-seven (27) in Range four (IV) on the official cadastre for the Township of Lynch, in the Electoral District of Laurentide-Labelle, (105.43 acres); This notice is published in conformity with section 209 of the Mining Act (1965, 1st Session, Chapter 34 and amendments).Signed in Québec City, on October 21, 1974.J.-G.Fredette, 58927 Deputy Minister.Ventes pour taxes Sales for taxes Ville de Saint-I.aureiit Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situes dans la Ville dc Saint-Laurent, seront vendus à l'enchère publique, à la palle du Conseil de l'Hôtel de ville, 777, boulevard Laurenticn, Saint-Laurent, LUNDI, le VINGT-CINQUIÈME jour de NOVEMBRE, 1974, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payes avant la vente.City of Saint-Laurent Public notice is hereby given that, the immovables described hereunder, situated in the City of Saint-Laurent, will be sold by public auction in the Council Hall of the City Hall.777 Laurentien Boulevard, Saint-Laurent, on MONDAY, the TWENTY-FIFTH day of NOVEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions CS.B.Realty Ud____ Gabriel Fonfeder et al.Joseph Origène April.Jean Légaré.493.P.3.Avec bâtisses / With buildings.493.P.3.Superficie/ Area: 107,519.0 pi.car./ sq.ft.P- 555.Superficie / Area : 2,224 pi.car./ sq.ft.257 .83.Avec bâtisses/ With buildings.468.247.248.Avec bâtisses / With buildings.468.249, 250. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, no U 8331 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions Nettoyeur Roy (1973) Inc.Mme Françoise G.Landry.Gérard Godbout.Mme Yvette Kirouac.409.409.409.241.242.468.468.468.468.468.239.259.472.Mrs.Lorraine J.S.Cohen.Fred-El Realties Ino.Bomac Building Corp.M.Maillet, Gilles Paquin et / and Guy Paquin.Dansereau et / and Poirier Ltd.231.233.234.Robert Besner.242.242.Mrs.Polixene V.Demakos.241.Helmut Thievessen.241.Harry Arnold et al.P.198.P.198 \u2014 Une partie du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-huit (P.198) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, division d'enregistrement de Montréal.Cette partie de lot d'une superficie de 420.847 pieds carrés, mesure anglaise, est bornée en front vers le nord-ouest par le Chemin Bois-Franc et également vers le nord-ouest par une partie non subdivisée du lot 198; vers le nord-est par le lot 199 et une partie non subdivisée du lot 198; vers le sud-est par le lot 197 et vers le sud-ouest par une partie non subdivisée du lot 198, propriété de l'Hydro-Québec.Edwards D.Watkins.87.Wilhelm Schueler.557.Mme Niza R.Avital.222.Pier Luigi Ruggeri.260 132A, 132.Avec bâtisses / With buildings.133, 133A, 134.135.1-76.Avec bâtisses/With buildings.1066.Avec bâtisses/ With buildings.P.770.Avec bâtisses / With buildings.P.768.P.769.710, 711.Avec bâtisses / With buildings.P.727.51, 52, 53.Avec bâtisses/ With buildings.57.Superficie / Area: 4,637.0 pi.car./ sq.ft.P.1, P.2, Avec bâtisses/ With buildings.P.473, P.473.4.Avec bâtisses/With buildings.4.4.561A.Avec bâtisses/With buildings.560A.296.Avec bâtisses/ With buildings.464.Avec bâtisses / With buildings.Superficie / Area : 420,847.0 pi.car./sq.ft P.198 \u2014 A part of the original lot number one hundred and ninety-eight (P.198) of the official cadastre of the Parish of Saint-Laurent, Registry Division of Montreal.This part of lot containing an area of 420.847 souare feet.English measure, is hounded in front towards the northwest by Bois-Franc Road and also towards the northwest by an unsubdivided part of lot 198; towards the northeast by lot 199 and an unsubdivided part of lot 198; towards the southeast by lot 197 and towards the southwest by an unsubdivided part of lot 198, property of Hydro-Québec.720.Avec bâtisses / With buildings.30.Avec bâtisses / With buildings.37.Avec bâtisses/ With buildings.253.Avec bâtisses / With buildings.Les immeubles susdits sont tous du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent et situés dans la Ville de Saint-Laurent.La Commission municipale, par une décision en date du 27 septembre 1974, a autorisé l'énumération abrégée des numéros de cadastres des propriétés ci-haut décrites.Donné à Saint-Laurent, ce lie jour d'octobre 1974.Le greffier, 58809-43-2-o Marc Blais.Ville de Gaspé Avis est par les présentes donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, que les immeubles ci-après décrits seront vendus aux enchères, à l'École des Arts et Métiers, rue Bolduc, Gaspé, MERCREDI, le VINGTIÈME jour de NOVEMBRE 1974, à DIX heures du matin, pour les taxes municipales et scolaires avec les intérêts, tels que mentionnés ci-après, à moins que lesdites taxes et les intérêts, ainsi que les frais, ne soient acquittés avant la date de la vente à l'enchère The above immoveables are all on the plan and book of reference of the Parish of Saint-Laurent and situated in the City of Saint-Laurent.The Québec Municipal Commission by a decision dated September 27th.1974.has authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the above immoveables.Given at Saint-Laurent, this 11th day of October, 1974.Marc Blain, 58809-43-2-o City Clerk.Town of Gaspé Notice is hereby given by the undersigned Secretary-Treasurer of the said municipality, that the properties hereinafter described, will be sold by auction at the Arts and Crafts School, Bolduc Street, Gaspé, on WEDNESDAY, the TWENTIETH day of NOVEMBER 1974, at TEN o'clock in the morning, to satisfy the payment of the municipal and school taxes with the interests, plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests, and cost, be paid before the sale. 8332 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Municipalité de Rivière-au-Renard \u2014 Municipality of Rivière-au-Renard Propriétaires Owners\tLots\tDescription\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tRépartition Allotment\tTotal Synnott, Charles.\t293-2 P.5-2.\tRing I, ouest, Canton Fox.R^ng I est.sud de la Rivière Canton Fox\t$ 2.11 4.02\ts 9.86\ts 6.90\t$ 9.01 13.88 Municipalité de Saint-Maurice\u2014 Municipality of Saint-Maurice\t\t\t\t\t\t Côté.Xavier.Tapp, Mme Joseph.\t443-1 P.369-7, 368, 392-8.366-19.399-1.\tRang I ouest, Canton Fox .Rang I ouest, Canton Fox .Rang I ouest, Canton Fox .Rang I ouest, Canton Fox .\t$ 54.91 9.70 41.73 5.82\t$ 53.66 41.65\t\t$108.57 9.70 83.38 5.82 Municipalité de Douglastown \u2014 Municipality of Douglaslown\t\t\t\t\t\t Cloutier, Frank, suce.Simoneau, Oliver.\tA-2 P.7-3.23 & 22.13-A-l.13-A-2, 13-A-3\tRang Bloc A, Canton Douglas Rang I, Bois Brûlé, canton Douglas Rang VIII de la Commune, Canton Douglas Rang I, Bois Brûlé, canton Douglas\t$ 9.84 1.98 103.94 17.24\t$15.54 2.34 165.94 27.98\t$ 3 00 94.50\t$ 25.38 7.32 364.38 45.22 Municipalité de York \u2014 Municipality of York\t\t\t\t\t\t Béchervaise, Mrs Charlot-te-Eva Miller, Rupert.Rooney, Napoléon.\t21.1-1A.19-1, B-l, 20-1 à 26-1, C-l 0-2-1 .N-4-A-1 .16 P.\tRang II, canton York.Rang I, canton York.Island of York River, canton York Island of York River, canton York Rang III, canton York.\t$ 9.16 125.63 1.26 3.02 2.72\ts 3.98\t\t$ 9.16 125.63 1.25 7.00 2.72 Municipalité de Saint-Majorique \u2014 Municipality of Saint-Majoriqut\t\t\t\t\t\t Bouchard, Paul-Aimé.Fortin, Arthem.Fournier, Achille.\t16 P.18 P.2.8.\tRang I sud, canton Sydenham Rang I sud, canton Sydenham Rang I sud, canton Sydenham Rang I Bud, canton Sydenham Rang ouest du Chemin, canton Baic-de-Gaspé-Nord\ts 69.85 47.95 6.41 62.72 5 89\t$337.23 126.48 4.80 131 39 43.46\t\t$407.08 174.43 11.21 194.11 49.35 Municipalité de Gaspé \u2014 Municipality of Gaspé\t\t\t\t\t\t Boulay, Arthur, Suce.Jalbert, Alfred.Lapierre, Gérard.\t119-J P.119-I-I.\tRang I, village de Gaspé Rang I, village de Gaspé.Rang I, village de Gaspé .\t$255.90 376.64 312.01\t$408.55 220.08\t\t$255.90 785.19 532.09 \tMunicipalité de Haldimand \u2014 Municipality of Haldimand\t\t\t\t\t Howell, Miles, Estate\t1-2.\tRang II nord, canton Douglas Rang II sud, canton Douglas\t$ 2.91 1.36\t$ 0.94\t$205.10\t$ 2.91 207.40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n' 44_8333 Propriétaires Owners\tLots\tDescription\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tRépartition Allotment\tTotal Lacouvée, Charles.Lacouvée, Reginald.Miller, Elmer.Miller, William Mrs.Suddard, Marion-May .Waddington.Mrs.William.Gault, William, Estate.\t4-C-l, 4-C-3.4-A-3, 4-A-4.4-B-l, 4-B-2 2.2.A-4.4-B-1-3.2 P.7-A-l, 7-A-3.4-3.\tRang I, Haldimand, canton Douglas Rang I, Haldimand, canton Douglas Rang II, canton Douglas Rang II nord, canton Douglas Rang I, Haldimand, canton Douglas Rang I, Sandy Beach, canton Douglas Rang II nord, canton Douglas Rang I, Hsldimand, canton Douglas Rang II sud, canton Douglas\tg 7.96 51.44 2.13 2.13 8.55 46.03 2.13 4.09 1.36\t% 12.41 316.21 3.47 3.47\tS 20.28\t8 20.37 387.93 5.60 5.60 8.55 46.03 2.13 4.09 1.36 Municipalité de Grande Grève\u2014 Municipality of Grande Grève\t\t\t\t\t\t Boulet, Laurent.Couture, Armand.\t10-C P.1-A P.\tRang I suc, canton Cap-des-Rosiers Rang I, sud, canton Cap-des-Rosiers\tS 1.81 5.81\tS 13.63\t\tt 1.81 19.44 Municipalité de Baie de Gaspé-Nord \u2014 Municipality of Baie de Qaspê-Nord\t\t\t\t\t\t Cassivi, Mme Jocelyne.Nicholls, Clyde & al.\tHP.33-B P.\tRang I, canton Baie-de-Gaspé-Nord Rang I, canton Baie-de-Gaspé-Nord\tS 13.33 1.51\t8 9.98\t\tS 23.31 1.51 Municipalité de Baie de Gaspé-Sud \u2014 Municipality of Baie de Gaspé-Sud\t\t\t\t\t\t Bond, Georges.Basque, Daniel.Shaw, Aurel.\t20-1, 20-4.5-C-4.47.8.30.32.6.3-9.\tRang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud Rang II sud, canton Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud Rang Darmouth, canton Baie-Gaspé-Sud\t3 24.37 144.10 7.46 6.18 0.84 16.49 30.58 25.00\t8 56.50 6.00 121.33\t\tS 24.37 200.60 7.46 6.18 0.84 22.49 30.58 146.33 Municipalité de Cap-des-Rosiers \u2014 Municipality of Cap-des-Rosiers\t\t\t\t\t\t Beauchemin, Normand.Ste-Croix, Gaétan.\t20 P.25-10.\tRang I est, canton Cap-des-Rosiers Rang I nord, canton Cap-des-Rosiers\tS 1.52 60.61\t8 63.02 41.71\t\ts 64.54 102.32 Municipalité dc Anse-au-Griffon \u2014 Municipality of Anse-au-Griffon\t\t\t\t\t\t Chouinard, Jean-Eudes .\t68-6.\tRang I sud, canton Cap-des-Rosiers\tS 46.27\tS 72.04\t|silS31\t s.Cil QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974.Vol.106.No.44 Propriétaires Owners\tLots\tDescription\tTaxes munie.Munie, taxes\tTaxes scol.School taxes\tRépartition Allotment\tTotal Pipon, Arnold-Picrro.Pipon, Bernard\t\tRant I sud.canton Cap-des-Rosiers Ran* I sud, canton Cap-des-Rosiers Rang I nord, canton Cap-des-Rosiers Rang I sud, canton Cap-des-Rosiers\tt 8 57 7.55 4.43 13.13\tS 7.41 49.14\t\tt 15 98 7 55 4 43 62.27 Les immeubles ci-liaut mentionnés sont du cadastre de la ville de Gaspé.Lesdites ventes seront en outre faites avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées aux immeubles.I.a Commission municipale, par une décision en date du 9 octobre 1974, a autorisé l'énumération abrégée des numéros de cadastres des propriétés ci-haut décrites.Donné à Gaspé, ce 10e jour d'octobre 1974.Condition: comptant.Le secrflaire-trhorier, 58808-43-2-o Gehald Bourdaofs.The above immoveables arc to the official plan and reference book of the Town of Gaspé.The said sales will be made with all active and passive servitudes, apparent or occult, attached to the properties.The Québec Municipal Commission, by a decision dated October 9th, 1974, authorized an abridged enumeration of the cadastral numbers of the above-mentioned immoveables.Given at Gaspé, this 10th day of October, 1974.Condition: Cash.Gerald Bocrdac:es, 58808-43-2-o Secretary-Treasurer.Ville d'Anjou Avis est par la présente donné, que le Conseil Municipal, par une résolution en date du 22ème jour d'octobre 1974, a ordonné au soussigné, conformément à la Loi des cités et villes de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Ville d'Anjou, avec intérêts et frais, et qu'en conséquence lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville d'Anjou 7701, Louis Hippolvte Lafontaine, le VINGT-SEPTIÈME jour de NOVEMBRE 1974.à DIX heures de l'avant-midi, heure normale dc l'est.Toutefois, seront exclus de la vente les immeubles sur lesquels les taxes municipales et scolaires, tant générales que spéciales de l'année 1973 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.Permission a été accordée par la Commission Municipale de Québec pour autoriser une enumeration abrégée des numéros cadastraux.Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d'un an, du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans les limites de la Ville d'Anjou.Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances s'il y a lieu, sujets à tous les droits acquis dc la Ville d'Anjou et à toutes les servitudes actives ou passives ou occultes pouvant les affecter.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale.City of Anjou Public notice is hereby given, that the City Council by a resolution dated October 22th 1974, has ordered the undersigned, pursuant to the Cities and Towns act: to sell the immovables hereinundcr described for nonpayment of taxation arrears owing to the corporation of the City of Anjou, with interest and cost, and that consequently the said immovables shall be sold by public auction in the Council room at the City Hall of Anjou, 7/01, Louis Hippolvte Lafontaine, City of Anjou, on the TWENTY-SEVENTH dav of NOVEMBER 1971 at TEN o'clock in the forenoon, eastern standard time.However, there shall be excluded from the sale, the immovables on which municipal and school taxes, so general as special for the year 1973 and previous years shall have been i>aid prior to the sale.The Québec Municipal Commission has authorized the City of Anjou, an abridged form of cadastral numbers.Immovables hereafter described will be sold, subject to the one-year right of redemption, of official cadastre of Parish Longue-Pointe, w ithin the limits of the City of Anjou.They shall be sold with buildings erected thereon, circumstances and dependencies if any, subject to all the acquired rights of the.City of Anjou, and any servitudes both active and passive, apparent or unap-parent which may affect them.The purchase price of said immovables shall be payable immediatly.in legal currency. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 novembre J974, 106' année, n° U 8335 (Les lots ci-après décrits sont du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe dans les limites de la Ville d'Anjou \u2014 The lois hereafter described are of the official cadastre of the Parish of Longue-Pointe in the limits of the City of Anjou).Nom et adresse Description de l'immeuble Folios Name and address Description of immovable 414-0116 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425, Snowdon Street, 414-261 Montréal, Québec 414-0142 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425, Snowdon Street.414-405 Montréal, Québec 414-0181 Arthur Samson, 571 Queen, Greenfield Park, Québec.414-507 415-0254 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-62 415-0255 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.414-63 415-0265 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-73 415-0266 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-74 415-0267 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-75 415-0268 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-76 415-0303 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, Québec 415-111 415-0310 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-118 415-0311 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-119 415-0325 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-133 415-0326 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-134 415-0327 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-135 415-0328 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-136 415-0331 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-139 415-0332 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-140 415-0345 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy.P.O.Bos 425 Snowdon St.Montréal, Québec 415-153 415-0373 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-181 415-0374 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg, Apt.509, Montréal, Québec.415-182 415-0375 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montrél, Québec.415-183 415-0376 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-184 415-040! Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-209 415-0402 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-210 415-0403 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-211 415-0404 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-212 415-0405 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-213 415-0477 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-285 415-0478 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-286 415-0479 Crémazie Investment Corp-.Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-287 415-0480 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-288 415-0485 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-293 415-0486 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-294 415-0488 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-296 415-0489 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-297 415-0490 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-298 415-0491 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-299 415-0492 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-300 415-0503 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-311 415-0504 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-312 415-0505 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-313 415-0506 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-314 415-0507 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-315 415-0508 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-316 415-0509 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-317 415-0510 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-318 415-0512 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-320 415-0513 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-321 415-0514 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-322 415-0515 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-323 415-0516 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-324 415-0517 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-325 415-0542 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-350 415-0543 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-351 415-0544 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-352 415-0549 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-357 415-0550 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-358 415-0551 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.416-359 415-0552 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-360 Vente d'immeubles pour non-paiement des taxes \u2014 Sale of immoveables for non payment of laxes QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1971,, Vol.106, No.U Folios Nom e: adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 415-0553 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-361 415-0554 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-362 415-0567 Crémazie Investment Corp-, Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-375 415-0668 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-376 415-0569 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-377 415-0572 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-380 415-0573 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-381 415-0574 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-382 415-0576 Crémazie Investment Corp-.Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal.Québec.415-383 415-0635 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal, Québec.415-427 415-0636 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.415-428 415-0637 Crémazie Investment Corp.Domnion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal Québec.Le lot 415-429.à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-429, to withdraw however the part used as a street.415-0639 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.Le lot 415-430, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 415-430, to withdraw however the part used ns a street.416-0646 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509, Montréal.Québec.415-434 415-0657 Crémazie Investment Corp.Dominion Sq.Bldg.Apt.£09, Montréal, Québec.415-445 415-0658 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.609, Montréal.Québec.416-446 415-0667 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg.Apt.509.Montréal, Québec.Le lot 415-453, à distraire toutefois la partie servant rie rue.Lot 415-453, to withdraw however the part used as a street.416-0007 Herman C.Steiner.580 Fifth Avenue, New York.N.Y., U.S.A.Un emplacement composé d'une partie du lot 416-490 conte- A site composed of a part of lot 416-490 containing an area nant une superficie de 488,562 pieds carrés, mesure anglaise et of 488.562 square feet, English measure and more or less and plus ou moins et borné comme suit,'savoir: au nord par des bounded as follows, to wit: on the north by parts of the said parties dudit lot 416-490, à l'est par une partie du lot 415-488.lot 416-490, on the east by a part of lot 416-488, on the south au sud dans une ligne oblique pur les limites de Ville d'Anjou by the collateral line following the limits of Ville d'Anjou and et à l'ouest par la ligne separative des terres 416 et 417.on the west by the separative line of the farms 416 and 417.417-0060 Epinette Construction Corp., 4275 Kent Avenue, Montréal.Québec.417-52 417-0061 Epinette Construction Corp., 4275 Kent Avenue, Montréal.Québec.417-53 417-0210 Epinette Construction Corp.4275 Kent Avenue.Montréal, Québec.417-197 417-0218 Sharand Construction Ltd.a/s Mme/Mre Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal.417-205 Québec 417-0219 Sharand Construction Ltd., a/s Mme/Mrs Foy.P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal.417-206 Québec 417-0252 Sharand Construction Ltd., a/s Mme/Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, 417-239 Québec 417-0253 Sharand Construction Ltd., a/s Mme/Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, 417-240 Québec 417-0285 Sharand Construction Ltd., a/s Mme/Mrs Foy, P.O.Box 426 Snowdon St.Montréal 417-272 Québec 417-0286 Sharand Construction Ltd., a/s Mme/Mrs Foy, P.O.Box 425 Showdon St.Montréal.417-273 Québec 417-0370 Sharand Construction Ltd.a/» Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St.Montréal, Québec 417-357 417-0372 Sharand Construction Ltd.a/s Mrs Foy.P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal.Québec 417-359 417-0376 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.417-363 417-0377 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost.Ville d'Anjuo.Québec.417-364 417-0378 Ernest Crépeault.7700.boul.Prévost.Ville d'Anjou, Québec.417-366 417-0379 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost.Ville d'Anjou, Québec.417-366 417-0380 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost, Ville d'Anjou.Québec.\" 417-367 417-0381 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.417-368 417-0382 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.417-369 417-0404 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, 417-391 Québec 417-0405 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal.Québec 417-309 417-0423 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.417-410 417-0424 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.,.417-411 417-0426 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, Québec 417-413 417-0427 Sharand Construction Ltd., a/s Mrs Foy, P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, Québec 417-414 417-0428 Sharand Construction Ltd., a/a Mrs Foy.P.O.Box 425 Snowdon St., Montréal, Québec 417-41 n 417-0461 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost.Ville d'Anjou, Québec.417-448 417-0658 Epinette Construction Corp.4275 Kent Avenue, Montréal.Québec.417-«UK 417-0597 Israel Herlick.648 Murray Hill, Westmount.Québec.417-W4 615-0108 Ernest Crépeault.7700.boul.Prévost.Ville d'Anjou.Québec.Ils is 515-0109 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost.Ville d'Anjou.Québec.4iaJtQ 6-0004 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost.Ville d'Anjou.Québec.418-40 5-0008 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost.Ville d'Anjou, Québec.418-41 5-0036 Giovanni Construction Ltée, 10220, Esplanade.Montréal, Québec.418-120 418-121 418-122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 s337 Folios Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 515-0240 Giovanni Construction Ltée, 10220, Esplanade, Montréal, Québec.418-123 515-0260 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-127 515-0264 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Montréal, Québec.418-128 515-0268 Edouard Lavoie, 6556, Des Ormeaux, Ville d'Anjou.Québec.418-129 418-130 295-0096 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Ar.jou, Québec.418-167 419-124 515-0408 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Ar.jôu, Québec.418-168 515-0412 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Ar.jou, Québec.418-169 295-0100 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-170 419-125 295-0134 Mme/Mrs Ernest Crépeault.née/born Marguerite Gratton, 7700, boul.Prévost, Ville 418-186 d'Anjou, Québec.419-133 295-0138 Mme/Mrs Ernest Crépeault, née/born Marguerite Gratton, 7700, boul.Prévost, Ville 418-187 d'Anjou.Québec.419-134 295-0142 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-190 419-135 295-0146 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-191 419-136 296-0150 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-194 419-137 515-0508 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-248 615-0512 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou, Québec.418-249 515-0518 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-251 515-0522 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-262 515-0526 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-253 515-0530 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-254 515-0538 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost, Ville d'Ar.jou.418-256 515-0542 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-257 515-0546 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-258 615-0550 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-259 615-0566 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-263 515-0570 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-264 615-0574 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-265 615-0578 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-266 515-0582 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-267 515-0586 Ernest Crépeault.7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.418-268 515-0720 Epinette Construction Corp., 4275 Kent Avenue, Montréal.Le lot 418-335, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 418-335, to withdraw however the part used as a street (Beauval) (Rondeau).(Beauval) (Rondeau).616-0005 Mathieu Colangelo.7332, Rondeau, Ville d'Anjou.418-342 615-0630 William Guy Rivest, 29, d'Avaugour, Duvernay, Laval.418-368 260-0054 William Guv Rivest, 29, d'Avaugour, Duvernay, Laval.418-376 260-0063 Jean Rock Lacoursière, 1909 - 6ième Avenue, Pte-aux-Trembles.418-377 419-370 295-0258 Mme/Mrs Rodrigue St-Juste, née/born Jeannine Marc, 6486 Souuth Ellis, Chicago, 418-384 Illinois.USA.419-362 295-0598 François Grandbois, 5318, Drolet, Montréal, Québec.419-283 419-284 260-0114 Rosaire Beaudoin, 6911, Guy, Ville d'Anjou.419-341 419-342-1 419-342-2 419-343-1 419-343-2 295-0436 Harry Flander, 7738, Lévesque, Ville d'Anjou.412\"?53 295-0742 Denis Dumont, 10529, Rancourt.Montréal, Québec.419-391 225-0030 Jean-Paul Cerat, Yves Sauvageau, 1610, De Bienville, St-Bruno, Québec.420-8 225-0034 Jean-Paul Cerat.Yves Sauvageau, 1610, De Bienville, St-Bruno, Québec.420-9 225-0074 Les Immeubles Anjou Ltée, 7700, boul.Yves Prévost.Ville d'Anjou, Québec.420-19 6-0121 Clément Proulx, 8795.Alexandre, Ville d'Anjou.420-240 420-241-1 270-0410 Joseph Wasserman, 172 Wexford Cr., Montréal, Québec.420-293 420-294 270-0418 R.A.Lynch, a/s Jos.Wasserman, 172 Wexford Crescent, Montréal.420-295 396-0636 Milan Lazic, 6998, Rhéaume, Ville d'Anjou.420-340-1 270-0434 Ernest Crépeault.Inc.7700, boul.Prévost, Ville d'Anjou.Une partie du lot 420-349 contenant une superficie de 3,773 A part of lot 420-349 containing an area of 3,773 square feet, pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée English measure and more or less and bounded as follows, to comme suit, savoir: au nord par une autre partie du lot 420-349, wit: on the north by another part of lot 420-349, on the east à l'est par le lot 420-348-2, au sud par la rue Chaumont (420-92) by lot 420-348-2, on the south by Chaumont street (420-92) et à l'ouest par la rue Guy (420-94).and on the west by Guy street (420-94). 8338 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 197i, Vol.106, No.U Folios Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 270-0446 Rosaire Beaudoin, 8904, Georges, Ville d'Anjou.420-350-2 420-351-1 270-0478 Claude Gauthier, 6993, Guy, Ville d'Anjou.420-356-2 420-357-1 270-0554 Claude Sanschagrin, 2130, rue Fleury, Montréal, Québec.- 420-379 345-0258 Mme Wladyslaw Derkacz, née/born Josephine Maykowska & Casemir Stanislawa, 420-389 Wladvsla A Michael Derkacz, 6993, Mousseau, Ville d'Anjou.345-0011 Roger Colas, 56, Maplewood, Outremont.-;\u2022,-\u2022\u2022\u2022:,-.ÏSrïSS! 225-0490 Lucien Hébert, 540.boul.Henri Bourassa O., Montréal.Québec.420-510 225-0502 Lucien Hébert.540, boul.Henri Bourassa O., Montréal.Québec.4?°r5;l! 225-0582 Immeubles Faust Inc., 6565.boul.Décarie, Montréal, Québec.420-548 345-0360 Roger Colas, 56 Maplewood, Outremont, Québec.420-561 345-0364 Roger Colas, 56 Maplewood, Outremont, Québec.420-562 345-0368 Roger Colas.56 Maplewood, Outremont, Québec.Ton?.270-0582 Roger Colas, 56 Maplewood, Outremont.Québec.420-564 270-0586 Roger Colas, 56 Maplewood.Outremont, Québec.î2°T?co 345-0372 Roger Colas.56 Maplewood, Outremont.Québec.420-568 270-0688 Roger Talbot.7325.Pierre Corneille.Appartement 114, Montréal, Québec.420-611 25-0126 Marcel Seaulicu, C.P.1726, Places d'Armes, Montréal, Québec.Le lot 423-94, à distraire toutefois la partie servant de rue Lot 423-94, to withdraw however the part used as a street (Azilda), avec bâtisses dessus construites, circonstances et (Azilda) with buildings erected thereon, appurtenances and dépendances.dependencies.25-0262 Ernest Crépeault, 7700, boul.Prévost.Ville d'Anjou.Le lot 423-129, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-129, to withdraw however the part used as a street.(Azilda).(Azilda) 25-0270 Ernest Crépeault, 7700.boul.Prévost.Ville d'Anjou.Le lot 423-130, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-130, to withdraw however the part used as a street.(Azilda) (Azilda) 25-0488 André Côté, 3220, boul.Lapointe.Montréal, Québec.Le lot 423-233, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-233.to withdraw however the part used as a street.(Azilda) (Azilda) 30-2232 Frank Dingle, 7022, Baldwin.Ville d'Anjou.o) Une partie du lot 423-305 mesurant cettedite partie 30 (a) A part of lot 423-305, measuring this said part 30 feet in pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une width by 72 feet in depth and containing an area of 2,160 superficie de 2,160 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou square feet, English measure and more or less and bounded as moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie follows, to wit: on the north by a part of lot 423-304, on the du lot 423-304, au sud par une partie du lot 423-306 décrite ci- south by a part of lot 423-306, as described below in b, on the dessus en 6, à l'ouest par des parties des lots 424-491-19 et west by parts of lots 424-491-19.424-491-18 and on the east 424-491-18 et à l'est par le résidu dudit lot 423-305.by the residue of said lot 423-305.b) Une partie du lot 423-306, mesurant cettedite partie 30 (b) A part of lot 423-306 measuring this said lot 30 feet in pieds de largeur par 72 pieds de profondeur et contenant une width by 72 feet in depth and containing an area of 2,160 superficie de 2,160 pieds carrés et plus ou moins et bornée square feet and bounded as follows, to wit: on the north by a comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-305, part of lot 423-305, as described above in a, on the south by a ci-dessus décrite en a, au sud par une partie du lot 423-307, à part of lot 423-307, on the west by other parts of lots 424-491- l'ouest par des parties des lots 424-491-18 et 424-491-17, â 18 and 424-491-17 and on the east by the residue of the said l'est par le résidu dudit lot 423-306.lot 423-306.30-1168 René Fontaine, 7075, Baldwin, Ville d'Anjou.Le lot 423-338, à distraire toutefois la partie servant de rue Lot 423-338, to withdraw however the part used as a street (Baldwin) avec bâtisses dessus construites, circonstances et (Baldwin) with buildings erected thereon, appurtenances and dependences.dependencies.25-1028 M.& Mme Edgar Pilotte, née/born Armande Bergeron, 6994, Azilda, Ville d'Anjou, Québec.o) Une partie du lot 423-380, mesurant cettedite partie 15 (a) A part of lot 423-380 measuring this said part 15 feet in pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une width by 67 feet in depth an containing an area of 1,005 square superficie de 1,005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou feet, English measure and more or less and bounded as follows, moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une autre to wit: on the north by another part of said lot 423-380, on the partie dudit lot 423-380, au sud par une autre partie du lot south by a part of lot 423-381, as described below in 6 on the 423-381, ci-dessous décrite en 6, à l'ouest par le lot 423-365 west by lot 423-365 (lane) and on the east by another part of (ruelle) et à 1 est par une autre partie dudit lot 423-380.the said lot 423-380.6) Une partie du lot 423-381, mesurant cettedite partie 30 (6) A part of lot 423-381 measuring this said part 30 feet in pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une width by 67 feet in depth and containing an area of 2.010 square superficie de 2,010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou feet, English measure and more or less and bounded as follows moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie to wit : on the north by a part of lot 423-380, as described above du lot 423-380 ci-dessus décrite en a, au sud par une partie du in a, on the south by a part of lot 423-382, on the west bv lot lot 423-382, à 1 ouest par le lot 423-365 (ruelle) et à l'est par le 423-365 (lane) and on the east by the residue of said lot 423- résidu du lot 423-381.381 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 10F,' année, no 44 8339 Folios Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 25-1088 Conrad Paquette, 1878, Hayes, Montréal, Québec.a) Une partie du lot 423-387 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-386, à l'est par le résidu dudit lot 423-387, au sud par une autre partie du lot 423-388 décrite ci-dessous en h et à l'ouest par le lot 423-365 (ruelle).b) Une partie du lot 423-388 mesurant cettedite partie 15 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 1.005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-387 décrite ci-dessus en a, à l'est et au sud par d'autres parties dudit lot 423-388 et à l'ouest par le lot 423-365 (ruelle) avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.25-1096 Conrad Paquette, 1878.Hayes, Montréal, Québec a) Une partie du lot 423-388 mesurant cettedite partie 15 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 1.005 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord et à l'est par d'autres parties dudit lot 423-388.au sud par une autre partie du lot 423-389 décrite ci-dessous en b et à l'ouest par le lot 423-365 (ruelle).b) Une partie du lot 423-389 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2.010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-388 décrite ci-dessus en a, à l'est par le résidu dudit lot 423-389 et â l'ouest par le lot 423-365 (ruelle) avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, (au sud par une partie du lot 423-390).(o) A part of lot 423-387 measuring this said part 30 feet in width by 67 feet in depth and containing an area of 2.010 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-386, on the east by the residue of said lot 423-387, on the south by a part of lot 423-388 described below in 6 and on the west by lot 423-365 (lane).(6) A part of lot 423-388 measuring this said part 15 feet in width by 67 feet in depth and containing an area of 1,005 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-387 described above in a, on the east and on the south by other parts of the said lot 423-388 and on the west by lot 423-365 (lane) with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.(a) A part of lot 423-388 measuring this said part 15 feet in width by 67 feet in depth and containingan area of 1,005square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north and on the east by other parts of said lot 423-388, on the south by a part of lot 423-389 described below in b and on the west by lot 423-365 (lane).(6) A part of lot 423-389 measuring this said part 30 feet in width by 67 feet in depth and containingan area of 2.010square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-388 described above in a, on the east by the residue of said lot 423-389, on the south by a part of lot 423-390 and on the west by lot 423-365 (lane) with buildings thereon erected, appurtenances and dependencies.25-1342 Mme Jules Grise, née/born Yvonne Miller & Julie Grise, 6955, rueAlizda, Ville d'Anjou.Le lot 423-427, à distraire toutefois la partie servant de rue Lot 423-427, to withdraw however the part used as a street (Azilda) avec bâtisses dessus construites, circonstances et dé- (Azilda) with buildings erected thereon, appurtenances and pendances.dependencies.30-1712 M.Mme/Mr.Mrs Richard Rabouin, née/born Simone Brown, 6557, rue Baldwin, Ville d'Anjou, Québec.Le lot 423-488, à distraire toutefois la partie servant de rue.Lot 423-488, to withdraw however the part used as a street.(Baldwin) (Baldwin) 25-1466 Cléophas Archambault, 6540.Azilda.Ville d'Anj a) Une partie du lot 423-519 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant, une superficie d.e 2,010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-518, à l'est par le résidu dudit lot 423-519, au sud par une partie du lot 423-520 décrite ci-dessous en 6 et à l'ouest par le lot 423-511 (ruelle).6) Une partie du lot 423-520 mesurant cettedite partie 30 pieds de largeur par 67 pieds de profondeur et contenant une superficie de 2,010 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 423-519 décrite en a ci-dessus, à l'est par le résidu dudit lot 423-520, au sud par une partie du lot 423-521 et à l'ouest par le lot 423-511 (ruelle).Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.ou, Québec.(a) A part of lot 423-519 measuring this said part 30 feet in width by 67 feet in depth and containingan area of 2,010 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-518, on the east by the residue of said lot 423-519, on the south by a part of lot 423-520 described below in b and on the west by lot 423-511 (lane).(b) A part of lot 423-520 measuring this said part 30 feet in width by 67 feet in depth and containingan area of 2,010square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 423-519 described above in a, on the east by the residue of said lot 423-520, on the south by a part of lot 423-521 and on the west by lot 423-511 (lane).With buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.30-2080 Jean-Louis Thibault, 5879, Baldwin, Ville d'Anjou, Québec.Le lot 423-614, à distraire toutefois la Dartie servant de rue Lot 423-614, to withdraw however the part used as a street (Baldwin) avec bâtisses dessus construites, circonstances et (Baldwin) with buildings erected thereon, appurtenances and dépendances.dependencies.25-1910 Yvon Normand & Jacques Boisvert, 41, St-Vallier, Repentigny, Québec.Le lot 423-626, à distraire toutefois la partie servant de rue Lot 423-626, to withdraw however the part used as a street (Azilda) avec bâtisses dessus construites, circonstances et (Azilda) with buildings erected thereon, appurtenances and dépendances.dependencies. 8340 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Folios Nom et adresse \\ame and address Description de l'immeuble Description of immovable 25-2118 Charles-A.Thibault, 132.13e Avenue, Lachine, Québec.Le lot 423-661, à distraire toutefois la partie servant de rue Lot 423-661, to withdraw however the part used as a street (Azilda) avec bâtisses dessus construites.circonstan et à l'ouest par des parties des lots Street (440-1253-P) and on the west by parts of lots «6 and loS'^iS Entreprises Lafleur 1962 Limitée, 60.Place Crémazie, Montréal, Québec.440-1216-1 222-0020 Entreprises Lafleur 1961 I imitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine 6., 440- 25^2 buite 300.Montréal, Québec.u,ri GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, n° U 8347 Folios Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 223-0058 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp Montréal, Québec.223-0063 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg., Québec.288-0221 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg., Québec.288-0425 Crémazie Investment Corp., Dominion Sq.Bldg., Québec.Une partie du lot 440-1257-8 contenant une superficie de 683 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une autre partie du lot 440-1257-8.à l'est par le lot 440-1258-17, au sud par le lot 440-1257-7 et à l'ouest par la rué Les Galeries d'Anjou (440-1254)., 1010, Ste-Catherine O.Suite 330.440-1257-4 1010.Ste-Cathenne O., Montréal.440-1257-3 1010, Ste-Catherine O., Montréal, 440-1257-7 1010, Ste-Catherine O., Montréal, A part of lot 440-1257-8 containing an area of 683 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by another part of lot 440-1257-8, on the east by lot 440-1258-17, on the south by lot 440-1257-7 and on the west by Les Galeries d'Anjou (440-1254).223-0062 288-0424 Yvan Nadon Construction Ltd., a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Québec.Yvan Nadon Construction Ltd., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Québec.Une partie du lot 440-1258-17 contenant une superficie de 2,036 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une autre partie du lot 440-1258-17.à l'est par une partie du lot 440-1258-6, au sud par le lot 440-1258-16 et à l'ouest par une partie du lot 440-1257-8.440-1258-3 A part of lot 440-1258-17 containing an area of 2.036 square feet English measure and more or less and bounded as follows to wit : on the north by another part of lot 440-1258-17.on the east by a part of lot 440-1258-6, on the south by lot 440-1258-16 and on the west by a part of lot 440-1257-8.288-0213 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010.Ste-Catherine O., Montréal, Québec.288-0217 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O.Montréal, Québec.288-0212 Yvan Nadon Construction Ltd., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.Suite 300, Montréal, Québec.288-0216 Yvan Nadon Construction Ltd., a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.288-0220 Yvan Nadon Construction Ltd.a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., Suite 300.Montréal, Québec.233-0208 Crémazie Investment Corp.a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.288-0120 Jean Perreault, 6072.Galeries d'Anjou, Ville d'Anjou.233-0212 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.Suite 300.Montréal, Québec.233-0204 Crémazie Investment Corp., a's Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.Suite 300, Montréal, Québec.233-0202 Crémazie Investment Corp.,a|s Eastern Devi.Corp.,1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.238-0060 Richard Brunet Inc., 1620, Linden, Montréal, Québec.238-0061 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.233-0134 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Québec.233-0138 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 300.Montréal, Québec.233-0142 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.233-0147 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.233-0146 Entreprises Lafleur 1961 Ltée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.233-0150 Entreprises Lafleur 1961 Ltée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Québec.233-0154 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.233-0158 Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec 238-0040 Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.Une partie du lot originaire 440-1266 contenant une superficie de 8,889 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée comme suit, savoir: au nord par une partie du lot 440-1268, à l'est par une autre partie du lot 440-1268 et par les lots 440-1266-13.440-1266-12, 440-1266-11, 440-1266-10, au sud par le lot 440-1266-19 et k l'ouest par le lot 440-1270 (rue du Bocage).440-1257-5 440-1257-6 440-1258-14 440-1258-15 440-1258-16 440-1260-13 440-1260-6 440-1261-6 440-1260-12 440-1260-14 440-1260-15 440-1261-9 440-1262 440-1264-5 440-1264-6 440-1264-7 440-1264-8 440-1266-14 440-1265-4 440-1265-5 440-1265-6 440-1265-7 A part of original lot 440-1266 containing an area of 8,889 square feet, English measure and more or less and bounded as follows, to wit: on the north by a part of lot 440-1268, on the cast by another part of lot 440-1268 and by lots 440-1266-13, 440-1266-12, 440-1266-11.440-1266-10, on the south by lot 440-1266-19 and on the west by lot 440-1270 (du Bocage Street). s:us QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.44 Folios Nom et adresse .Vame end addreat Description de l'immeuble Description of immovable 238-0065 288-0129 288-01 33 288-0136 288-0140 288-0144 288-0149 288-0153 2SX m 57 288-0101 288-0169 233-0151 233-0155 233-0159 233-0162 233-0166 288-0128 288-0148 288-0152 288-0156 288-0160 288-0164 288-0168 288-0165 233-0179 233-0183 233-0187 233-0191 233-0174 233-0178 233-0182 233 (118(1 233-0190 233-0175 233-0074 40-0076 \u2022ni on so in onsi 10 (Kiss Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O,, Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, ^^ué bec Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O.Montréal, Québec.Crémazie investment Corp., a/s Eastern Devi.Copr.1010.Ste-Catherine O.Suite 300.Montréal, Québec.\u201e , Crémazie Investment Corp.a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 300.Montréal, Québec._ \u201e \u201e .Crémazie Investment Corp.a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.Suite 300, Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010.Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp.Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 509, Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 10111, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp.Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O-, Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp.Dominion Square Bldg.1010, Ste-Catherinc O.Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp.a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O.Suite 300.Montréal.Québec.Richard Brunet Inc., a/s Eastern Devi.Corp.1010 Ste-Catherine O., Suite 300.Montreal, Québec.Richard Brunet Inc.a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Québec.Richard Brunet Inc., a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine 0., Suite 300.Montréal, Québec.Richard Brunet Inc., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine 0., Suite 300, Montréal, Québec.Richard Brunet Inc., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.Suite 300.Montréal, Québec.Richard Brunet Inc., a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec.Richard Brunet Inc., a/a Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., Suite 300.Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp.Dominion Square Bldg.1010.Ste-Catherine O.Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O.Montréal, Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal.Québec.Crémazie Investment Corp., Dominion Square Bldg., 1010, Ste-Catherine O., Montréal, Québec.1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal.Emile Asselin, a/s Eastern Devi.Corp., Québec.Emile Asselin, a/s Eastern Devi.Corp.Québec.Emile Asselin, a/a Eastern Devi.Corp., , Québec.Emile Asselin, a/a Eastern Devi.Corp., Québec.Emile Asselin, a/s Eastern Devi.Corp., Québec.Crémazie Investment Corp.Dominion Sçuare Bldg., 1010.Ste-Catherine O., Montréal Québec.Crémazie Investment Corp., a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O.Suite 300, Montréal, Québec.Emile Asselin.40.Elmwood.Outremont.Emile Asselin, 40, Elmwood.Outremont.Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.Emile Asselin, 40.Elmwood, Outremont.1010.Ste-Catherine 0., Suite 300, Montréal, 1010, Ste-Catherine 0., Suite 300, Montréal, 1010.Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, 440-1266-2 440-1266-3 440-1266-4 440-1266-5 440-1266-6 440-1266-7 440-1266-8 440-1266-9 440-1266-10 440-1266-11 440-1266-13 440-1269-2 440-1266-16 440-1266-16 440-1266-17 440-1266-18 440-1266-19 440-1267-2 440-1268-1 440-1268-2 440-1268-3 440-1268-4 440-1268-5 440-1268-6 440-1266-12 440-1269-1 440-1271-3 440-1271-4 440-1271-5 440-1271-6 440-1272-1 440-1272-2 440-1272-3 440-1272-4 440-1272-8 440-1271-2 440-1273 440-1282-1 440-1282-2 440-1282-3 440-1282-4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 10G' année, n° U 8349 Folios Nom et adresse Name and addrets Description de l'immeuble Description of immomie 40-0092 Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.440-1282-5 40-0096 Emile Asselin.40, Elmwood, Outremont.440-1282-6 40-0100 Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.440-1282-7 40-0104 Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.440-1282-8 40-0108 Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.440-1282-9 40-0112 Emile Asselin, 40.Elmwood.Outremont.440-1282-10 40-0116 Entreprises Lnfleur.1961 Limitée, 1010, Ste-Catherine O., Suite 300, Montréal, Québec Une partie du lot 440-1282-11 contenant une superficie de A part of lot 440-1282-11 containing an area of 1.594 square 1.594 pieds carrés, mesure anglaise et plus ou moins et bornée feet, English measure and more or less and bounded as follows, comme suit, savoir: au nord par la rue Beaubien (440-1284), to wit: on the north by Beaubien Street (440-1284), on the à l'est par le lot 440-1285, au sud par le lot 440-1367 et à l'ouest east by lot 440-1285, on the south by lot 440-1367 and on the par le lot 440-1282-10.west by lot 440-1282-10.40-0056 Emile Asselin, 40, Elmwood, Outremont.440-1289 288-0836 Emile Asselin, Att.: R.Boucher, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1290 Suite 300, Montréal, Québec.177-0132 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1321 Suite 300, Montréal.Québec.177-0136 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.440-1322 Suite 300.Montréal.Québec.177-0140 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., Suite 300.Montréal, Québec 440-1323 177-0144 Entreprises Lafleur, a,s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O., Suite 300, 440-1324 Montréal, Québec.177-0148 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, »| s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1325 Suite 300, Montréal, Québec.177-0152 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1326 Suite 300, Montréal, Québec.181-0044 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1331 Suite 300, Montréal, Québec.181-0048 Entreprises Lafleur 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1332 Suite 300, Montréal, Québec.181-0052 Entreprises Lafleur.1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste.Catherine O., 440-1333 Suite 300, Montréal, Québec.181-0056 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010.Ste-Catherine O.440-1334 Suite 300, Montréal, Québec 181-0060 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1335 Suite 300, Montréal, Québec.181-0064 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.440-1336 Suite 300, Montréal, Québec.181-0068 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1337 Suite 300, Montréal, Québec.181-0076 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp.1010.Ste-Catherine O.440-1338 Suite 300, Montréal.Québec.181-0080 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.440-1339 Suite 300, Montréal, Québec.177-0060 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O.440-1343 Suite 300, Montréal, Québec.177-0064 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1344 Suite 300, Montréal, Québec.177-0068 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp., 1010, Ste-Catherine O., 440-1345 Suite 300, Montréal, Québec.177-0072 Entreprises Lafleur.1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., 440-1346 Suite 300, Montréal, Québec.177-0076 Entreprises Lafleur, 1961 Limitée, a/s Eastern Devi.Corp.1010, Ste-Catherine O., 440-1347 Suite 300, Montréal, Québec.\u201e-naire 47/, au sud par les lots 477-78.the said original lot 477, on the south bv lots 477-78, 477-79 477-/9 et 4/ ,-80 et à I ouest par la partie du lot originaire 475 and 477-80 and on the west bv the part of the original lot 475 oecrite en ti.described in b.90-0020 Paul André Mathieu, 7380, Champclievrier.Ville d'Anjou.473-27 90-0060 Mme-Mrs.J.Guy Boivin, née-born Jeanninne Vallée, 7293, Champchevrïer, Ville 473-37 d Anjou.4-?i?2,0?Larissa Development Corp., 1.Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal.H3B 3Y8____ 473-158 îiïi&SÎ Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie, Suite3317, Montréal, H3B3Y8____\" 473-159 V-Î~7z£.Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B3Y8____.\" 473-160 SS.« Larissa DeveopmentCorp., 1, Place Ville Marie.Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.473-161 ï«L/EmS ['ar!ss;< Development Corp.1, P ace Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.473-162 V-i~E?Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie.Suite 3317.Montréal H3B 3Y8____ 473-163 4/3-0224 Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.473-164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n° 44 8351 Folios Nom et adresse Name and address Description de l'immeuble Description of immovable 577-0120 Ernest C.Edouard Poulin, 7312, Vernantes, Ville d'Anjou.186-0008 Mme-Mrs.Jean-Guy Dumas, née-born Marguerite Cadorette, 9051, De Bretagne, Ville d'Anjou.275-0056 Stephen Sauvé, Jr.7332, Jarry, Ville d'Anjou.475-0009 Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.475-0352 Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie.Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.475-0356 Larissa Development Corp., 1, Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.475-0360 Larissa Development Corp., 1.Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.475-0364 Larissa Development Corp.1, Place Ville Marie, Suite 3317.Montréal H3B3Y8.475-0372 Larissa Development Corp.1, Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.475-0376 Larissa Development Corp.1.Place Ville Marie, Suite 3317, Montréal H3B 3Y8.211-0020 José, Grilli Sr., 7771, Querbes.Montréal.477-0232 Giovani Di Pierro, 9063.De Louress, Ville d'Anjou.477-0280 Larissa Development Corp., 1.Place Ville Marie.Suite 3317.Montréal H3B 3Y8.477-0284 Larissa Development Corp.1.Place Ville Marie, Suite 3317.Montréal H3B3Y8.210-0092 Mme-Mrs.Bernard Dupuis, née-born Suzanne Laplante, 8325.Haut d'Anjou, Ville d'Anjou.483-0009 Fidelity Holdings Ltd., 2090, Chartier, Dorval.355-0052 Marcel Martineau, 7260, L'Assomption, Montréal, Québec.249-0068 Claude Aubin, 7060.Azilda.Ville d'Anjou.320-1500 Goodyear Tire & Rubber Co., Canada Ltd.c/o Law Depart., 3050, Lake Shore Boul.West, Toronto, Ontario.208-0008 Goodyear Tire & Rubber Co., Canada Ltd.co/ Law Depart., 3050, Lake Shore.West.Toronto, Ontario.355-0169 Montreal Platefab Ltd., 9751, Parkway, Ville d'Anjou.390-0036 Nicholas Chryssolar.Alfred M.Steiner Jr., 355, Seigneural est, St-Bruno, Québec- 473-168 473-171 475-230 475-60 475-170 477-80 475-171 475-172 476-173 475-174 475-176 475-177 475-207 477-65 477-78 477-79 477-81 483-16 484-3 485-6 484-50 485-54 486-50 485-56 486-52 487-16-1 488-12 489-22 489-9-2 489-10 En foi de quoi, j'ai signé ce présent document, ce 23ème jour d'octobre 1974.Le greffier, 58894-44-2-0 Léonce Maltais, o.m.a.In testimony whereof, I have signed this present document, this 23th day of October 1974.Léonce Maltais, o.m.a., 58894-44-2-0 City Clerk.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses E.H.PRICE SALES LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « E.H.PRICE SALES LIMITED », a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.George P.MacFadyen.gérant, 3333, boulevard Cavendish, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 3333, boulevard Cavendish, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58868-0 1358-7423 E.H.PRICE SALES LIMITED Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act \"E.H.PRICE SALES LIMITED\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is Mr.George P.MacFadyen, 3333 Cavendish Boulevard, Montreal.The principal office of the company in the Province is located at 3333 Cavendish Boulevard, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 1358-7423 8352 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 A.I.S.RESOURCES LIMITED Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 16 octobre 1974, il a accordé un nouveau permis à la compagnie « ALLIED INVESTORS SYNDICATE LIMITED », l'autorisant à compter du 21 septembre 1971, à vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, dans la province de Québec, sous son nouveau nom « A.I.S.RESOURCES LIMITED », conformément aux dispositions de la Loi des compagnies minières, Statuts refondus, 1964, chapitre 283.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58868-0 P.V.A.11-70 A.I.S.RESOURCES LIMITED The Minister of Financial Institutions.Companies, and Cooperatives gives notice that on October 16,1974, he granted a new authorization to \"ALLIED IN\\ ES-TORS SYNDICATE LIMITED\", authorizing it, from September 21, 1971, to sell or otherwise alienate directly or indirectly in the Piovince of Québec, under its new name \" À.I.S.RESOURCES LIMITED\", in conformity with the provisions of the Mining Companies Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 283.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 P.V.A.11-70 CONOCO MINERALS INCORPORATED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « CONOCO MINERALS INCORPORATED », a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins dc recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Robert L.Munro, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1, Place Ville-Marie, suite 750, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.58868-0 PA: 38-73 KEB-OTT FOOD BROKERS INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « KEB-OTT FOOD BROKERS INC.», a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.George A.Heaven.1, lie Rue, Roxboro.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 5465.chemin Queen Mary, suite 500, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.58868-o 1356-7193 CONOCO MINERALS INCORPORATED Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act.\"CONOCO MINERALS INCORPORATED\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is Mr.Robert L.Munro, of Montreal.The principal office of the company in the Province is located at 1 Place Ville-Marie.Suite 750.Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 PA: 38-73 KEB-OTT FOOD BROKERS INC.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act.\"KEB-OTT FOOD BROKERS INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company is Mr.George A.Heaven.1 - 11th Street.Roxboro.The principal office of the company in the Povince is located at 5465 Queen Mary Road, Suite 500.Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.58868 1356-7193 Soumissions \u2014 Demandes de Tenders \u2014 Requests for Cité de Saint-Hyacinthe City of Saint-Hyacinthe Comté de Saint-Hyacinthe County of Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que des sou- Public notice is hereby given that sealed tenders missions cachetées et portant l'inscription « Soumis- marked \"Tenders for bands\" will be received by the sions pour obligations» seront reçues par le soussigné undersigned.André Comeau, Citv Clerk, at the Citv Andre Comeau, greffier, Hôtel de ville, 1450, rue Gi- Hall, 1450 Girouard Street, Saint-Hvacinthc Countv GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n' U 8353 rouard, Saint-Hyacinthe, comté de Saint-Hyacinthe, P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 18 novembre 1974 pour l'achat de $378,000 d'obligations de la cité de Saint-Hyacinthe, comté de Saint-Hyacinthe, datées du 15 décembre 1974 et remboursables en série du 15 décembre 1975 au 15 décembre 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 10%, ni supérieur à 11%, payable semi-annuellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 15 décembre 1974.Tableau d'amortissement \u2014 $378,000 \u2014 20 ans Date Capital 15 12 1975.$ 8,000 15 12 1976.8,000 15 12 1977 .9,000 15 12 1978.10,000 15 12 1979.11,000 15 12 1980.12,000 15 12 1981.13,000 15 12 1982.14,000 15 12 1983.15,000 15 12 1984.16,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4\" Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $37,000 et si supérieur à ce dernier montant, cet excèdent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 15 décembre 1994.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.of Saint-Hyacinthe, P.Q., until 8:30 o'clock p.m., on Monday, November 18, 1974 for the purchase of a bond issue of $378,000 for the City of Saint-Hyacinthe, County of Saint-Hyacinthe, dated December'15, 1974 and redeemable serially from December 15, 1975 to December 15, 1994 inclusive, with interest at a rate of not less than 10%, nor more than 11%, payable semiannually on June 15th and December 15th of each year.The rate of interest may be the.same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from December 15, 1974.Rédemption table \u2014 9378,000 \u2014 20 years Date Capital 15 12 1985.$18,000 15 12 1986.19,000 15 12 1987.20.000 15 12 1988 .22,000 15 12 1989 .24,000 15 12 1990.26,000 15 12 1991.30,000 15 12 1992.32,000 15 12 1993.34.000 15 12 1994.37.000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth j-ear.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $37,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of December 15, 1994.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure. 8354 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2.1974, Vol.106, No.44 Insolites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $37,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 15 décembre de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Saint-Hyacinthe s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 15 décembre 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.LeaditM obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 959 \u2014 $110,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 961 \u2014 $244,000 \u2014 usine dc filtration; 978 \u2014 $24,000 \u2014 participation à la construction de H.L.M.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou dc l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue lundi, le 18 novembre 1974, à 8.30 heures du soir.Hôtel de ville, 1450, rue Girouard, Saint-Hyacinthe, comté de Saint-Hyacinthe, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Hyacinthe (Comté de Saint-Hyacinthe), ce 22 octobre 1974.Le greffier, André Comeau.Hôtel de ville, 1450, rue Girouard, Saint-Hyacinthe, ( '< ¦ i r 11 TELECABLE DES MILLE-ILES INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-o 1368-6340 TELECABLE DES MILLE-ILES INC.Notice is given that, under the Part I of the Compa-mies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent of \"TELECABLE DES MILLE-ILE INC.\", published in the Québec Official Gazette, number 38, dated September 21, 1974, on page 6888, by replacing in the said name the word \"MILLE-ILE\" by \"MTELE-ILES\", in order that said name read as follows:\" TELECABLE DES MILLE-ILES INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.58868 1368-6340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106- année, n' 44 8389 INTERCINE INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de situation du siège social de la compagnie « INTERCINE INC.», paru le 5 octobre 1974, à la page 7160 du numéro 40 de la Gazette officielle, en y remplaçant dans ledit nom le mot « IXTERCINE » par « INTERCINE », de manière que le nom se lise ainsi: « INTERCINE INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 720793 ROULOTTES R.G.GAGNON INC.Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes de la compagnie « ROULOTTES R.G.GAGNON », parue le 5 octobre 1974 à la page 7154 du numéro 40 de la Gazette officielle, en y ajoutant dans ledit nom le mot « INC.», de manière que le nom se lise ainsi: « ROULOTTES R.G.GAGNON INC.».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.58868-0 1369-6158 INTERCINE INC.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to correct the notice of location of head office of \"IXTERCINE INC.\", published in the Québec Official Gazette dated October 5, 1974, number 40, on page 7160, by replacing the word \"IXTERCINE\", in the Company's name, by the word \"INTERCINE\".in order that said name read as follows: \"INTERCINE INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.58868 720793 ROULOTTES R.G.GAGNON INC.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent of \"ROULOTTES R.G.GAGNON\", published in the Québec Official Gazette, number 40, dated October 5, 1974, on page 7154, by adding in the said name the word \"INC.\", in order that said name read as follows: \"ROULOTTES R.G.GAGNON INC.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.58868 1369-6158 LES ENTREPRISES DeCASSON LTEE Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de lettres patentes de la compagnie « LES ENTREPRISES DECASSON LTEE and its English version DECASSON ENTERPRISES LTD.», paru le 5 octobre 1974, à la page 7151 du numéro 40 de la Gazette officielle, en y remplaçant dans ledit nom le mot « DECASSON » par « DeCASSON », de manière que le nom se lise ainsi: « LES ENTREPRISES DeCASSON LTEE and its English version DeCASSON ENTERPRISES LTD.».Le directeur du service des compagnies, 58868-0 Pierre Desjardins.1357-4348 Municipalité de Perkins Municipalité de Portland-Ouest Canton de Wakefield, partie Est L'avis de requête pour fusion des municipalités de Perkins.Portland-Ouest et du Canton de Wakefield, partie Est, publié dans la Gazette officielle du Québec, partie I, du 19 octobre 1974.à la page 7921, doit être corrigé de la façon suivante : Dans les versions française et anglaise, le nom de la municipalité de Portland-Ouest doit être enlevé partout où il apparaît afin que cette requête ne contienne que les noms des deux seules municipalités requérantes à savoir: Municipalité de Perkins et Canton de Wakefield, partie Est.58910-o DeCASSON ENTERPRISES LTD.Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice of letters patent of \"LES ENTREPRISES DECASSON LTEE and its English version DECASSON ENTERPRISES LTD.\", published in the Québeo Official Gazette dated October 5, 1974, number 40, on page 7151, by replacing therein the word \"DECASSON\", in the Company's name, by the word \"DeCASSON\", in order that said name read as follows: \"LES ENTREPRISES DeCASSON LTEE and its English version DeCASSON ENTERPRISES LTD.\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.58868-0 1357-4348 Municipality of Perkins Municipality of Portland-West Township of Wakefield, East Part The notice of petition for the amalgamation of the Municipalities of Perkins, Portland-West and of the Township of Wakefield, East Part, published in the Québec Official Gazette, Part I, dated October 19, 1974, on page 7921, should be corrected as follows: In the French and English versions, the name of the Municipality of Portland-West should be deleted wherever it appears in order that said petition include only the names of the only two petitioning municipalities, namely : The Municipality of Perkins and the Township of Wakefield, East Part.58910 8390 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol.106, No.U Parish of Saint-Martin In issue number 43, dated October 26, 1974, on page 8107, the 4th line should have read: \"lot 624-64\" instead of: \"lot 624-62\". GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 197J,, 106- année, n° U 8391 INDEX N© 44 Partie I: avis juridiques \u2014 Part I: Juridical notices AVIS DIVERS Arvida, munie.(Requéte-Petition).Club d'auto neige Castor inc.(L.P.).Église Baptiste Évangélique de Victoriaville (Requéte-Petition) .Estate of André Doyon (Benefit of Inventory).Estates of Danielle Bourdon and Gilles Robert (Benefit of Inventory).Immeubles Authier ltée (Les) (L.P.S.) (Correction).Jonquière, munie.(Requéte-Petition).Kénogami, munie.(Requête-Pétition).Marcana Resources Limited (Siège social-Head office).Moniales rédemptoristines de Sainte-Thérèse (L.P.).Saint-Dominique-de-Jonquière, munie.(Requéte-Petition).Succession André Doyon (Bénéfice d'inventaire).Succession Danielle Bourdon et Gilles Robert (Bénéfice d'inventaire) .MISCELLANEOUS NOTICES 8292 8315 8316 8316 8317 8316 8292 8292 8317 8315 8292 8316 8317 CHANGEMENT DE NOM \u2014 Loi du CHANGE OF NAME ACT Demandes: Applications: Cauchon, Joseph Louis Marie.8318 Cauchon (Paré), Raynald.8320 Claude, Joseph Roger Jean.8318 Drain, Jean-Claude.8320 Ferris, Laurie Earl.8317 Paquet, Pamela.8320 Paré, Joseph Gabriel Jacques.8318 Radwinski, Stanislaus.8318 Schroeder, Klaus Hans Georg.8318 Sheito, Salim (Salomon) Thouma et als.8319 Simard, Marie, Joseph, Estelle Clotilde.8319 CAISSES D'EPARGNE ET DE CRÉDIT SAVINGS AND CREDIT UNIONS Caisse d'épargne et d'entraide économique de Québec (Mod.terr.).8323 Caisse Populaire de l'Auvergne (La) (Nom- Name ch.).8323 Caisse populaire Yamaska (Erratum).8387 COMMISSION Québec Transport Commission COMMISSION Commission des transports du Québec Avis de la Commission « proprio motu ».8276 Avis de décisions rendues.8276 Avis d'introduction de requêtes.8237 Notice \"proprio motu\" by the Commission 8276 Notice of decisions rendered.8276 Notice of submission of applications.8237 COMPAGNIES ÉTRANGÈRES EXTRA-PRO VINCI AL COMPANIES Permis: Licenses: A.I.S.Resources Limited.8352 Conoco Minerals Incorporated.8352 Keb-Ott Food Brokers Inc.8352 Price (E.H.) Sales Limited.8351 Siège social: Boston Factors International, Inc.COMPAGNIES \u2014 LOI DES Abandon de charte Head office: .8320 COMPANIES ACT Surrender of Charter Biblio-Hachette inc.8173 Bouchard (Yves) inc.8173 Boulangerie Morrissette inc.8173 Boutique Harriett* inc.8173 Centre d'enseignement intensif de langues (Montréal) inc.8173 Doucet Automobiles inc.8173 Falc-Rich Inc.8173 Industrial Concrete Floor Finishing Co.Ltd.8173 Intensive Language Teaching Center (Montreal) Inc.8173 8392 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 8, 1974, Vol- 106, No.U Administrateurs Directors (Article 84) (Section 84) Arcam inc.8155 Chemico-Pharmaceutical Company, Inc.8155 Compagnie de fabrication Cylindrix inc.8155 Compagnie Pharmaco-Chimique, inc.8155 Cylindrix Mfg.Co.Inc.8155 Dessin P.L.U.S.inc.8155 Industries P.H.L.inc.8155 Moulin Blanc inc.(Le).8155 Muje inc.8155 Multidick Inc.8155 P.L.U.S.Design Inc.8155 Paré & Graham inc.8155 Placements la Toscane ltée (Les).8155 Québec Mack Inc.8155 Services de lubrifiants industriels et commerciaux (SLIC) inc.8155 Société de gestion immobilière Fleury, Perron & Associés ltée.8155 Tuscany Holdings Ltd.8155 Veillette inc.8155 White Mill Inc.(The).8155 Changement dc nom Change of name Amis des écoles chrétiennes d'Egypte (Les) 8171 Athens Music Centre Inc.(Erratum).8387 Centre hospitalier Cooke (Erratum).83S7 Centre de musique Athènes inc.(Erratum) 8387 Centre de théâtre Laurentien.8171 Charette (Jacques) and Associates Ltd.8171 Charette (Jacques ) et Associés ltée.8171 Club Dawson pour garçons et filles (Le).8171 Coldor Inc.8171 Compagnie des ventes Lorraine ltée (La).8171 Compass Investments of Québec Ltd.8171 Dawson Boys' and Girls' Club (The).8171 Disques T.B.limitée (Les).8171 Ford Electric Supply Ltd.8171 Fournitures électriques Ford ltée.8171 Foyer du Frioul inc.(Le).8171 Investissements Compas du Québec ltée (Les) 8171 Laurentian Theatre Centre.8171 Longueuil Refrigeration, Plumbing & Heating Inc.8172 Lorraine Sales Company Ltd.8171 Offset Ville-Marie Inc.8172 Planetarium Silk Screen Inc.8172 Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc.8182 Salon du décor du Saguenay inc.8172 Sérigraphie Planétaire inc.8172 Servico Limited.8172 Servico limitée.8172 Super marché Victoria inc.8172 Thermatic Ltd.8172 Thermatic ltée.8172 Victoria Super Market Inc.8172 Demandes d'abandon Applications for de charte Surrender of Charter Brookmere Development Corporation.8197 Cie de contrôle Swift ltée (La).8198 Cleco Electric Company (1969) Ltd.8198 De Martin-Morana of Canada, Ltd.8196 Erdicklnc.8197 Fondation Age d'Or du Québec inc.8197 Gabriel (Mario R.) inc.8199 Immeubles Landhold ltée (Les).8198 Landhold Properties Ltd.8198 Lumic limitée.:.8197 Montreal Blue Print Incorporated.8198 Placements Roma inc.(Les).8196 Swift Controls Co.Ltd.8198 Taverne 3700 inc.8196 Transport Bernard ltée.8199 Divers Miscellaneous Shufelt, Berridge & Company Limited (Disk actif-assets).8321 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) Abattoirs Saint-Basile inc.8156 Aberford Sporting Club.8156 Accessoires et outillage d'autos Baby inc.8156 Accessory Embroidery inc.8156 Adcla Realty Ltd.8156 Adiia Travel Service Inc.8156 Aetna Factors Corporation Ltd.8156 Aetna Factors Corporation Ltd.8156 Aetna Factors Corporation Ltd.8156 Agenas Park-King Inc.8156 Agence de voyage Adria inc.8156 Aliments Papineau inc.(Les).8167 Allaire, Cinq-Mars et Associés inc.8156 Alliance Fami-Ski inc.8156 Aloha Steak House inc.8156 Amédya Enterprises Ltd.8156 Aménagement Woodmore ltée.8171 Anden Inc.8156 Angreen Exhibits Ltd.,.8156 Annis Inc.'.8156 Anshell Industries Inc.8156 Antirouille Protec inc.8168 Appartements Candiac inc.(Erratum).8380 Appartements Lubeau inc.8156 Arco Construction (Immeubles) ltée.8157 Arjay Holdings Inc.8157 Arler Land Holdings Inc.8157 Arol Chemical Co.Ltd.8157 Association de c.& p.des métalos inc.8157 Association de camping de Montmagny-LTslet inc.8157 Association catholique de jeunes Ukrainiens (UCYMA).8170 Association des citoyens du centre d'affaires de Montréal (L').8160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 10b' année, n° U 8393 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) (suite) (continued) Association des maitres-couvrcurs du Québec (L1).8157 Association Québec-France (I/).8157 Association des vétérans belges du Québec inc.;.8157 Assurance Aime Duclos inc.8160 Atlific Inns Inc.8157 Atlific Longueuil Inc.8157 Attache-remorques de Montréal inc.(Les).8157 Autobus Rochon inc.(Les).8157 Babv Autos Parts Inc.8157 Balance Trading Ltd.8157 Balayeuses Kirby inc.(Erratum).8382 Barré Street Realty Company (Erratum).8383 Beam Montreal Realty Ltd.8157 Beauvais (Max) limitée.8157 Bellefieur & Frères inc.8157 Beloeil Furniture Shop Inc.8158 Benaby Realties Ltd.8157 Bernstein (J.M.) & Sons Inc.8157 Bicycles Primeau inc.8168 Blackwood Hodge Québec Ltd.8157 Bloor Holdings Ltd.8158 Bootery Limited.8158 Bourgault Transport limitée.8158 Boutique du meuble de Beloeil inc.8158 Boutique de modes Rita inc.8158 Brosseau (Jean-Claude) inc.8158 Brownstein (H.) Inc.8158 C.C.Interiors Inc.8158 Cadillac Investments, Ltd.(Erratum).8380 Canadian Contact Lens Laboratories Ltd.8158 Cardinal Cleaning Services Inc.8158 Car-Park Inc.(Erratum).8382 Casualaire inc.8158 Centre d'achat Laprairies ltée.8164 Centre des piscines québécoises inc.8158 Chabri inc.8158 Charbonneau (Marcel) ltée.8158 Chartier (Vincent) inc.(Erratum).8383 Chauret (Léo) construction inc.8158 Chomedey Tire Inc.8168 Ciment L.G.P.inc.8158 Citation Investment (1971) Corp.8158 Club Albéric Gagnon inc.8158 Club Anne Marie inc.8158 Club du Bouclier.8158 Club Castor Dore (Erratum).83S1 Club de camping et caravaning Côte Xord inc.8158 Club équestre St-Maurice inc.8158 Club Ile aux saumons inc.8159 Club du lac Gabriel inc.8159 Club Lazon.8159 Club Mayrand inc.(Erratum).8383 Club Mo'rinback Inc.8159 Club des Neiges Sorel-Tracy inc.8158 Club Richelieu Saint-Jérôme.8159 Club Rio (Erratum).8386 Club St-André Lac-St-Jean inc.8159 Club de Salaberry inc.8159 Club Tonti inc.(Erratum).8381 Cobctto (D.) and Sons.8159 Coffrage Ste-Foy inc.8159 Coiffuradlnc.8159 Collin (Gérard) inc.8159 Collins (D.A.) Inc.8159 Combo Realties Inc.8159 Comité du centre sportif Rouville inc.8159 Communications (Québec) inc.8159 Confection Johanne inc.8159 Construction Boulevard Léger ltée.8159 Construction L.& H.Bessette ltée.8159 Construction & pavage nord-américain ltée.8166 Corporation de l'arsenal inc.(La).8159 Corporation des citoyens de Parc Extension (La).8167 Corporation d'investissement Pajo (La).8167 Corporation de promotion d'habitations de Hull.8159 Couillard (G.) automobile inc.8159 Coursol (André) inc.8160 Cox Lake Fish & Game Club.8160 Craimer Associates Ltd.8160 Crankshaft Grinding & Diesel Service Inc.{Erratum).8386 Crémerie Mont Blanc ltée.8160 Croustilles Yum-Yum inc.(Les).8160 Cyfbel ltée (Erratum).8382 Dale Plumbing Ltd.8160 Dankoff's Delicatessen & Steak House Inc.8160 Daviau (M.) inc.8160 De Salaberry Motors Inc.8160 Deschênes (A.) transport inc.8160 Désilets (Jean-Paul) inc.8160 Deslauriers (Napoléon) & Fils inc.8160 Diamond Taxicab Asssociation Limited.8160 Distriouteurs M & L inc.(Les).8165 Distributions B.R.S.ltée.8160 Dominion Floral Co.8160 Donna Fashions Mfg.Ltd.8160 Doré (Jean) and Associates Inc.8160 Doré (Jean) et Associés inc.8160 Downtown Citizens' Association of Montreal Inc.8160 Duclos (Aimé) Assurance Inc.8160 Dufresne (Gérard) inc.8161 Duquette Club Wobe Maquaw.8161 E.T.Tent & Awning Co.Ltd.(Erratum)____ 8386 Eastern Cleaning Services Ltd.8161 Eastern Fire Protection Inc.8161 Echo Realties Ltd.8161 Edelweiss Lounge Inc.8161 Editions Kebecspec inc.8161 Editions populaires (Montréal) inc.8161 Edwards Electric Ltd.8161 Empire Distributors Ltd.8171 Ensembles urbains limitée (Les).8161 Entrepreneurs Martin & Michel ltée (Les) 8161 8394 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November s, 1974, Vol.106, No.44 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) (suite) (continued) Entreprises Alphaser inc.8161 Entreprises Charles-E.Roy inc.(Les).8161 Entreprises D.D.B.limitée (Les).8161 Entreprises Gilles Godbout inc.(Les).8161 Entreprises immobilières R.G.D.inc.(Les).8161 Entreprises J.G.C.inc.8161 Entreprises J.M.Saucier inc.(Les).8161 Entreprises Kimo inc.8161 Entreprises M.Bourgault ltée (Les).8161 Entreprises Pierre et Marcel Dulude inc.(Les) 8161 Entreprises XXe siècle inc.(Les).8162 Entreprises Yamaco limitée (Les).8162 Equipco Limited.8162 Equipement de restaurant National inc.8166 Erection Breton ltée.8162 Europa Technic Ltd.8162 Expo-sciences de Montréal inc.8162 Fédération de patinage à roulettes du Québec (La).8162 Fédération de water-polo du Québec (La).8162 Fein Canadian Power Tool Company (Québec) Ltd.8162 Ferland (J.P.) et Frère inc.(Erratum).8381 Ferme Joliette inc.(La).8162 Fondation Bergeron inc.8162 Formaccntre inc.(Erratum).8383 Forms and Systems Limited.8162 Francoeur Investments Ltd.8162 François, Pierre and Associates Ltd.8162 François, Pierre et associés ltée.8162 Functional Music SSS Limited.9162 Gaby Footwear (1972) Ltd.8162 Gagné (J.M.) inc.8162 Gates (Peter) Inc.8162 Gauthier Rental Inc.8164 Gemscreen Advertising Ltd.8162 Gemscreen Advertising Ltd.8162 Gemst Ltd.8163 General Products Company.8163 Georgia Taxi Co.8163 Géorgie Girl Lingerie Limited (Erratum).8382 Girard (L.) transport inc.8163 Glenco Investment Corp.8163 Globensky (Gilles) inc.8163 Golden Brand Clothing Inc.8163 Gronbri Contractors Ltd.8163 Gryphon Associates Ltd.8163 Harbour Electrix Inc.(Erratum).8386 Head & Hands Inc.8163 Hemisphere Consolidation Ltd.8163 Hcrlich Insurance Inc.8163 Hôtel Plaza (Macamic) inc.8163 Houde (Gratien) ltée.8163 House of Hose Inc.8163 Huiles G.et C.Beaulieu ltée (Les).8163 Huiles Orléans limitée (Les).8163 Immeubles Echo ltée (Les).8161 Immeubles La Crémière ltée (Les).8163 Immeuble St-Donat inc.8163 Immobilia Builders Inc.8163 Impex A & L Incorporated.8163 Industries Anshell inc.(Les).8156 Industries Palmar ltée.8167 Installations électriques A.F.D.inc.(Les).8163 Installations électriques Desjardins inc.8164 Intérêts Roger Hénaire inc.(Les).8164 Intérieurs C.C.inc.(Les).8158 International Parking Ltd.8164 Investissements Carrefour ltée.8164 Investissements Magog-Orford inc.(Les).ol64 Iseman (I.) Limited.8164 Jardins Carmel inc.(Les) (Erratum)).8383 Jardin Sakura inc.8168 Jarry & Frère co.ltée.8164 Karls (Ben) Incorporated.8164 Kirby Vacuum Cleaners Inc.(Erratum).8382 L'Acadie Industriel Park Inc.8164 Lachance (Léandre) & Associés inc.8164 Laflamme (Michel) inc.8164 laiterie de Sept-Iles ltée.8164 Laprairie Shopping Centre Ltd.8164 Lemire (Yvon) inc.8164 Lespérance Construction Ltd.8164 Lespérance construction ltée.8164 Lettre (Rooert) inc.8164 Lévesque (Albéric) ltée.8164 Lévesque (J.E.) inc.8164 Lipo Chemicals Lid.8164 Location Gauthier inc.8164 Loisirs du boulevard, inc.(Les).8164 Loisirs communautaires de St-Roch de Québec 8165 L'Ouest commercial et professionnel inc.(Erratum).8384 M.J.J.Co.Inc.8165 M.K.Plastics Ltd.8165 M & L Distributors Inc.8165 M & S Painters Inc.8165 Mabra Holdings Inc.8165 Magasin à rayons Shier ltée.8165 Maison Secrestat ltée (La).8165 Malartic Auto Ltd.8165 Maple Leaf Lodge No.10250, Grand United Order of Odd Fellows, Incorporated.8165 Marcan Ltd.8165 Marchands du centre d'achat Rock Forest inc.(Les).8165 Marché Boxer inc.8165 Marchés Mailhot inc.(Les).8165 Marois (Aurèlc) inc.8165 Mart Realties Corp.8165 Martha Holdings Corp.8165 Marton's Stores Inc.8165 Masivor Corporation.8165 McArthur Holdings Ltd.8165 McGill College Holdings Ltd.(Erratum).8384 Melnick Food Products Inc.8165 Mendel Investments Corp.8165 Mergl (A.) Construction Inc.8166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, n\" U 8395 Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) (suite) (continued) Métairie de la Providence inc.8166 Metropolitan Loan Corp.8166 Michael's Restaurant Inc.8166 Minicomp Inc.8166 Min-Roe Investment Corporation.8166 Mitchinamekus Club.8166 Modes Rayna inc.(Les).8166 Monorail industrie ltée (Erratum).8384 Montreal Trailer Hitch Inc.8157 Morin (Claude) inc.8166 Motel Bel-Air inc.8166 Motel Carignan inc.8166 Moteurs Dc Salaberry inc.8160 Multidickinc.8166 Musique fonctionnelle SSS limitée.8162 Myrand (Emile) inc.8166 N'.J.Realty Company Ltd.8166 Nahtoya Hunting & Fishing Club Inc.(Erratum).8384 National Restaurant Equipment Inc.8166 Nettoyeurs Villeneuve inc.8166 Noms (A.A.) & Co.Ltd.8166 North American Construction & Paving Ltd.8166 North End Food Services Inc.8166 Norval Investment Corporation.8166 Nouveau magasin renommé inc.(Le).8166 Nozets, Greenfield Associates Inc.8167 O-Na-Home Limited.8167 Pajo Investment Corporation.8167 Palmar Industries Ltd.8167 Panorama Construction Inc.8167 Papineau Foods Inc.8167 Paradis (J.N.) limitée.8167 Parc industriel de l'Acadie inc.8164 Park Extension Community Corporation 8167 Pasard Inc.(Erratum)._.8385 Pâtisserie La Bonne Brioche, inc.8167 Patro de Lévis inc.(Le).8167 Pauzé (Rosario) inc.8167 Pentecostal Benevolent Association of Québec (The) (Erratum).8385 Perrault (Paul) construction ltée.8167 Place Vieille Capitale inc.8167 Placements Delmer inc.(Les).8167 Placements Fortier ltée (Les).8167 Placements Francoeur ltée (Les).8162 Placements Gérard Lemieux inc.(Les).8167 Placements J.M.Sauvé ltée (Les).8167 Placements Sardi ltée (Les).8169 Placements Septimo inc.8167 Pladyn Inc.8167 Planned Investments Corporation (Erratum) 8385 Plastiques Sylvia inc.(Les).8167 Plomberie Dale ltée (La).8160 Plomberie St-Claude inc.8167 Pneu Chomedey inc.8168 Poéti (Pierre) inc.8168 Polan Realty Corp.8168 Polyclinique de l'entreprise inc.8168 Polycom Group Inc.(The).8168 Poivres Inc.8168 Primeau Bicycles Inc.8168 Productions Bovegas ltée.8168 Production Covip limitée.8168 Productions du Verseau inc.(Les).8168 Programmes d'investissements capitalisés, ltée (Erratum).8385 Pro pen Investments Ltd.8168 Pross Woollens Inc.8168 Protec Rust Proofing Inc.8168 Québec fleuriste inc.8168 Québec Master Roofers Association.8157 Québec Roller Skating Federation (The)____ 8162 Québec Water-Polo Federation.8162 Rayna Fash ions Inc.8166 Ray-Vas Investment Corp.(Erratum).8385 Rcpmont construction ltée.8168 Restaurant M.Dilallo inc.8168 Rim inc.8168 Rita's Fashion Boutique Inc.8158 Roco Inc.(Erratum).8381 Rouleau (F.G.) inc.(Erratum).8381 Rouse Québec Ltd.8168 Rouse Québec ltée.8168 Rugtech Inc.8168 Sr.Donat Real Estate Inc.8163 St.George International Inc.8168 St.Louis Legal Services.8169 Saint Malo Heating Limited.8168 Sakura Garden Inc.8168 Sardi Investments Ltd.8169 Sarosi Shoes Ltd.8169 Scbaefer (A.) Ltd.8169 Séguin & Tessier inc.8169 Sept-Iles Dairy Ltd.8164 Services d'administration Sherbrooke inc.8169 Service & distribution PV inc.8169 Services juridiques de St-Louis.8160 Service des loisirs St-Nicolas.8169 Service des loisirs St-Pascal.8169 Service des loisirs Visitation.8169 Sen-ices de lubrifiants industriels & commerciaux (SLIC) inc.8169 Services de transport Steve limitée (Les).8169 Shawinigan auto location inc.8169 Sherbrooke Administrative Services Inc.8169 Sherbrooke Décor & Rénovation inc.8169 Shetland Investment Corporation.8169 Sintra Inc.8169 Site de camping Le Glte inc.8169 Skimontlnc.8169 Société financière Mercure inc.8169 Société de placement Essort incorporée.8169 Stéréo Musica inc._.8170 Steve Cartage Service Limited.8169 Supermarché J.C.Bédard ltée.8170 Swift (M.) & Sons (Canada) Ltd.8170 Sylvia Plastics Inc.8167 S396 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1971,, Vol.106, No.U Domicile légal Legal domicile (Article 30) (Section 30) (suite) (continued) TCD Limited.8170 Tabson Textiles Ltd.8170 Tasco Laboratories Inc.8170 Telem Inc.8170 Thiry, Bourgoin & Associés inc.(Erratum) 8386 Tour Eiffel limitée (La).8170 Trailer Equipment Limited.8170 Trudeau Transport Inc.8170 Turgeon (G.A.) ltée.8170 Ukrainian Catholic Young Men's Association (UCYMA).8170 Valois (Léo) & Fils inc.8170 Veilleux (Laurent) ltée.8170 Vellra Oil Ltd.8170 Viking Oil Resources Inc.8170 Vitrerie Desmarais ltée.8170 W.L.Plastic & Metal Producer Company Limited.8170 Walker Manufacturing Co.Ltd.8170 Waltson Properties (Québec) Ltd.8170 Whiterock Industries Ltd.8170 Woodmore Development Ltd.8171 Yum-Yum Potato Chips Inc.8160 Fusion Amalgamation de compagnies of companies Corporation draperies Montreal (La).8172 Montreal Draperies Corp.8172 Publications du Nord-Ouest inc.8172 Lettres patentes Letters Patent (1- partie) (Part I) A.S.P.Holding Corporation.8182 Ackren Ltd.8178 Ackren ltée.8178 Alberto of Italy Knitwear Ltd.8191 Aliments des Indes Occidentales Ramdas ltée.8178 Alimentation Clément Paré inc.8179 Alimentation Gilles Tremolay inc.8179 Alimentation J.E.Roy inc.8179 Aluminium Simard & Guillemette inc.8179 A mal fi Landscaping Inc.8187 Aménagement Canterbury ltée.8179 Aménagement Caralon inc.8179 Aménagements immobiliers M.W.Z.ltée.8179 Aménagement Magnum inc.8179 Aménagements S e-Anne-des-Mon^inc.(Les) 8179 Aménagement St-Elzéar inc.8179 Ameublemen Beaumont inc.8179 Ameublement, du manufac.urier Blainville inc.8179 Amyot (Roger) inc.8179 Anac Construction Ltd.8182 Antiquités de la vieille Europe inc.8179 Arcamoinc.8179 Argyle Realty Corp.8182 Articles de sports Lacourse inc.W Artisanat Lanea inc.8179 Association des citoyens de la Rive-Sud (L').\u2022 8179 Association des propriétaires de chalets de la rivière Franquelin.8180 Atelier du meuble ancien Coculet inc.(L').8180 Atfa Enterprises Inc.8183 Auto Réal Ménard ltée.8180 Autobus G.D.inc.(Les).8180 Autobus Lamothe & Gagné inc.(Les).8180 Axe Industries Inc.8186 B.& P.Tile and Terrazzo Inc.8190 Bar Salon Lynn, Granby inc.8180 Bar Salon Micheline, Granby inc.8180 Batimex inc.8180 Beaver Manufacturing Corporation.8183 Béland (Jos.) inc.8180 Bergeron (A.) & Associés inc.8180 Besner et Lamanque inc.8180 Betshel Investments Ltd.8188 Bijouterie M.Bolduc inc.8180 Bijouterie Richelieu inc.8180 Bisson (Claude) Furs Inc.8184 Bontemps & Leblanc ltée.8180 Boulanger (E.L.) inc.8180 Bourassa (S.) ltée.8180 Bourbonnais et Leblanc inc.8180 Bourgon et Fils inc.8180 Boutique Le Regard inc.8180 Boutique Mode Jeunesse de Montréal ltée.8180 Boutique Virage inc.8180 Brasserie Patelin ltée.8180 Brasserie St-Pascal inc.8181 Brevets Eurocan ltée.8181 C.B.K.Wholesale Plumbing Supply Ltd.8185 C.J.Auto Body Inc.8181 Café Gigolette inc.8181 Cantem Industries Ltd.8186 Canterbury Development Ltd.8179 Caralon Development Inc.8179 Carillon Tool & Dye Inc.8187 Caron (Robert), Chaussures inc.8181 Caron (Venant) Matane ltée.8181 Carosserie d'autos C.J.inc.8181 Carrière Landreville inc.8181 Centre artisanal de l'Ile aux Coudres inc.8181 Centre du bricoleur J.A.K.inc.8181 Centre du camion Beauce inc.8181 Centre musical Chez Duke inc.8181 Centre de recherche du vieux Montréal sur l'enseignement des sciences et des techniques-.8181 Centre sportif Wilson inc.8181 Centre de vêtements en gros (Québec) limitée.8181 Chapados (Médard) inc.8181 Charbonneau vJean-Paul), entrepreneur élec- ricienltée.8181 Châteauguay Development Ltd.8182 Ciné Sahret inc.8181 Clauri inc.8181 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, n' 44 8397 Lettres patentes Letters Patent (l™ partie) (Part I) (suite) (continued) Club des motoneigistes du lac William inc.(Le).87S1 Club récréatif des ressortissants de Frosolone.8781 Comauvi inc.8181 Compagnie maritime québécoise (C.M.Q.) ltée.8182 Compagnie de plomberie et chauffage D.K.inc.8182 Compagnie de réfrigération Nordique inc.(La).8182 Compagnie Régitan ltée (La).8182 Concareinc.8182 Confection Alapo inc.8182 Confection Leblanc (1974) inc.8182 Constantineau (F.) & Fils inc.8182 Construction Anac ltée.8182 Constructions domiciliaires Châteauguay ltée 8182 Construction Gapiane inc.8182 Constructions Lebrun & Tremblay inc.8182 Construction Maretal inc.8182 Construction Quanta inc.8182 Construction Rolland Plante inc.8182 Container Systems (Québec) (1974) Limited 8191 Corporation d'électronique Shefford.8182 Corporation de gestion A.S.P.(La).8182 Corporation d'immeubles Argyle.8182 Corporation des manufactures Castor.8183 Corporation de placements Renaud (La).8183 Corporation Takless (Québec) ltée.8183 Couturier (Raymond) inc.8183 Créations Saad inc.8183 D.K.Plumbing and Heating Inc.8182 D.M.Refrigeration Inc.8189 Dalumo Industries Ltd.8186 De Casson Enterprises Ltd.(Erratum).8389 Décoration Claudette Desmarais inc.8183 Demobec inc.8183 Desmarais (Claudette) Decoration Inc.8183 Distributions T.N.R.inc.8183 Distribution Tonipro inc.8183 Domaine Air Pur inc.8183 Domaine du lac Martin inc.8183 Domaine R.G.N.inc.8183 Double Hook Book Shop Inc.(The).8186 Draperie canadienne inc.(La).8183 École de boxe Drouin inc.8183 École de conduite St-Pascal inc.8183 Entrepôts M.D.G.inc.(Les).8183 Entreprises Atfa inc.(Les).8183 Entreprises Cité Jeune ltée (Les).\u2022 8183 Entreprises De Casson ltée (Les) (Erratum) 8389 Entreprises de drainage G.H.F.C.inc.(Les) 8183 Entreprises Fragiskos incorporée.8183 Entreprises immobilières W.G.inc.8184 Entreprises Jascar ltée (Les).8184 Entreprises Jover ltée (Les).8184 Entreprises L.F.inc.8184 Entreprises Les Sept ltée (Les).8184 Entreprises Lesrie inc.(Les).8184 Entreprises Lionel Guilbault inc.(Les).8184 Entreprises Rod Malay inc.(Les).8184 Entreprises Roger Chaput, Granby inc.(Les) 8184 Entreprises touristiques Tikouape inc.(Les) 8184 Entreprises W.D.G.S.ltée (Les).8184 Équipements de bureau Inter-Cité inc.8184 Estampillage Lasry inc.8184 Eurocan Patents Ltd.K.8181 Ewing & Records Inc.8184 Exar Research Corporation Limited.8190 Excavations Daigle inc.(Les).8184 F.C.Automobile Leasing Matane Ltd.8186 Fastex inc.8184 Fer ornemental D.P.inc.8184 Fleuriste Eve inc.8184 Fleuriste Luc Roy inc.8184 Fourniture de linge Vaudreuil inc.8184 Fourrures Claude Bisson inc.8184 Friemar Marine Service Ltd.8190 Gagnon (G.C.) Realties Inc.8185 Galli Masonry Ltd.8187 Garage C.-E.Tremblay inc.8185 Garage D.& M.Biais inc.8185 Gelbec inc.8185 Gemini Holdings Inc.8188 Gestion Conseil de Montréal inc.8185 Gestion Pima limitée.8185 Gestions W.Kaiser ltée.8185 Gloria Illustrations Inc.8185 Golden (C.) and Associates Ltd.8185 Golden (G) et Associés ltée.8185 Grossiste en plomberie C.B.K.ltée.8185 Grou Holding Ltd.8188 Guatama inc.8185 H.R.E.Industries Ltd.8186 Habitations A.Pascal inc.(Les).8185 Harlee Investments Ltd.8188 Illustrations Gloria |inc.8185 Immeubles G.C.Gagnon inc.(Les).8185 Immeubles J.M.Legault inc.(Les).8185 Immeubles Marashco ltée (Les).8185 Immeubles Moclar inc.(Les).8185 Immeubles Rebok ltée.8185 Immeubles Semar ltée (Les).8185 Immeubles H-L.G.inc.(Les).8185 Immeubles Yip inc.(Les).8186 Import-Export C.D.M.ltée.8186 Imprimerie Le Roy-Audy inc.8186 Industries Axe inc.(Les).8186 Industries Cantem ltée (Les).8186 Industries Dalumo ltée (Les).8186 Industries H.R.E.ltée (Les).8186 Industries Rolbec inc.(Les).8186 Inkel & Frères inc.8186 Inter-City Office Equipment Inc.8184 Investissements Sylvana inc.8186 Izzo Brothers Landscape Contractors Ltd- 8187 Jace Investments Inc.8188 Jalbert (Eddy) inc.8186 Jardins Beaulieu inc.(Les).8186 8806 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.U Lettres patentes Letters Patent (1- partie) (Part I) (suite) (continued) Jouets Pri ne-Val inc.8186 Jover Enterprises Ltd.8184 Kaiser (W.) Holdings Ltd.8)85 L.G.G.Clothing Limited.8191 Laboratoire de photo couleur Sollevanti inc 8196 Laferrière & Cordeau ltée.8186 Lanea Handicraft Inc.8179 Larose Saunas Inc.8190 I,asry Stamping Inc.8184 Lebrun & Tremblay Constniction Inc.8182 Leisure Time Restaurants Inc.8189 Librairie Double Crochet inc.(La).8186 Ligue de taxis de Beloeil inc.(La).8186 Location d'automobiles P.C.Matanc ltée.8186 Location de grues Montréal ltée.8187 Look Boutique Inc.8180 Lougec Inc.8187 M.D.G.Storage Inc.8183 M.W.Z.Property Development Ltd.8179 Maçonnerie Galli ltée.8187 Magama Inc.8187 Magnum Development Inc .8179 Maisons usinées Landry inc.8187 Malay (Rod) Enterprises Inc.8184 Marashco Realties Ltd.8185 Marché Fernand Graveline inc.8187 Marché Yvon Dezainde inc.8187 Maretal Construction Inc.8182 Marquis Lafleur inc.8187 Mason (R.) inc.8187 Mediom Autio-Scripto-Visual Production Services Inc.(Erratum).8388 Ménard, Marsan & Associés inc.8187 Ménard (Real) Auto Ltd.8180 Merrctt (Brian) & Jennifer Harper Inc.8187 Métaux Werner inc.(Les).8187 Metropolitan Painting Inc.8188 Mini Auto Sport St-Léonard inc.8187 Moclar Estates Inc.8185 Molida Investments Ltd.8188 Monette (Maurice) ltée.8187 Montreal Crane Rentals Ltd.8187 Motel La Campagne inc.8187 Navigation G.Tremblay ltée.8187 O.D.S.Organization Design Services Ltd____ 8190 Old Europe Antiques Inc.8179 Outils et teintures Carillon inc.8187 Paquelte (Roger D.) et Associés ltée.8187 Paysagistes Amalfi inc.8187 Paysagistes Izzo et Frères ltée (Les).8187 Peinture métropolitaine inc.8188 Peinture R.et R.Presser inc.8188 Péladeau (Jacques) inc.8188 Pierre à mur futuriste de Val-Bélair inc.8188 Piraa Management Limited.8185 Pistilli Supermaket Inc.8191 Place Béréli inc.8188 Placements A.St-Germain inc.8188 Placements Le Bec-Fin inc.(Les).8188 Placements Betshel ltée.8188 Placements Distinction inc.8188 Placements Gémeaux inc.(Les).8188 Placements Grou ltée (Les).8188 Placements Harlee ltée.8188 Placements J.D.limitée.8188 Placements J.P.Viau inc.8188 Placements Jace inc.(Les).8188 Placements K.B.D.inc.(Les).8188 Placements Molida ltée.8188 Placements Valjou inc.(Les).8188 Plantations Baume de Weedon inc.(Les).8189 Prodimpex inc.8189 Productions Tévéquoises limitée (Les).8189 Produits d'acier Roger inc.(Les).8189 Produits chimiques R.L.inc.(Les).8189 Produits électroniques Vandor ltée.8189 Promaction inc._.8189 Promotions Admix inc.8189 Prosser (R.and R.) Painting Inc.8188 Proulx (Marcel) et Associés (1974) inc.8189 Quanta Construction Inc .8182 Quincaillerie Paul Larouche ltée.8189 Quincaillerie St-Laurent ltée.8189 Ramdas West Indian Foods Ltd.8178 Ravary (R.) & Associés inc.8189 Rebok Properties Ltd.8185 Réfrigération D.M.inc.8189 Regitan Company Ltd.8182 Renaud Investments Corporation.8183 Renosaginc.8189 Restaurant Le Bouffe-en-Broche inc.8189 Restaurant Chez Gisèle Forget limitée.8189 Restaurant Jardin de Capri inc.8189 Restaurants Moments Libres inc.8189 Restaurant Sai Woo inc.8189 Revêtements de céramique et de lerrazzo B.& P.inc.8190 Richelieu Jewellery Inc.8180 Rioux et Paquet inc.8190 Robert Spring Service Inc.8190 Roederer (Louis) & Associés inc.8190 Roger's Steel Products Inc.8189 Rolbcc Industries Inc.8186 Roulottes R.G.Gagnon inc.(Erratum).8389 Roy (J.P.) and Associates Inc.8190 Roy (J.P.) et Associés inc.8190 Ste.Anne-des-Monts Development Inc.8179 St-Germain (J.A.) (1974) inc.8190 St-Lawrence Hardware Ltd.8189 Saad Creations Inc.8183 Sai Woo Restaurant Inc.8189 Salon de beauté de la femme de l'an 2,000 inc.8190 Saunas Larose inc.8190 Sauvé (Jean-Paul) inc.8190 Séchoirs à bois René Bernard ltée (Les).8190 Sécurité Sélect inc.8190 Select Security Inc.8190 Semard Realty Ltd.8185 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, no 44 8399 Lettres patentes Letters Patent (V partie) (Part I) (suite) (continued) Services maritimes Friemar ltée (Les).8190 Services de productions audio-scriptovisucls Mediom inc.(Les) (Erratum).8388 Service de projets d'organisation O.D.S.ltée.8190 Service de ressorts Robert inc.8190 Shefford Electronics Corporation.8182 Simard & Guillemette Aluminium Inc.8179 Société d'administration D.L.inc.(La).8190 Société d'art et décoration Yves Prévost inc.8190 Société de gestion F.L.M.inc.8190 Société immobilière McDerpoz inc.8190 Société immobilière Québec .Métropolitain inc.8190 Société de recherche Exar limitée.8190 Sollevanti Photo-Color Laboratory Inc.8186 South Shore Citizens Association.8179 Spancol Inc.8191 Station de ski l'Elan.8191 Supermarché Pistilli inc.8191 Sylvana Investments Inc.8186 Systèmes dc Containers (Québec) (1974) limitée.8191 Takless Corporation (Québec) Ltd.8183 Tania Textiles Inc.8191 Tapis Tanguay inc.(Les).8191 Tardif, Gingras and Associates Inc.8191 Tardif, Gingras et Associés inc.8191 Tardif (J.-Maurice) inc.8191 Télécâble des Mille-Iles inc.(Erratum).8388 Télémissib limitée.8191 Télévision et stéréo Express inc.8191 Textiles Tania inc.(Les).8191 Touchctte et Legault inc.8191 Tournée des gfands spectacles de Sorel (La).8191 Traversier Le Passeur inc.8191 Tricots Alberto d'Italie ltée.8191 Triple E Sales Ltd.8191 Valmorno Inc.8191 Vandor Electronic Products Ltd.8189 Vaudreuil Linen Supply Inc.8184 Ventes Triple E ltée (Les).8191 Ventes Yanow ltée (Les).8191 Vêtements L.G.G.limitée.8191 Viau (J.P.) Investments Inc.8188 Weedon Balsam Plantations Inc.8189 Werner Metals Inc.8187 Wholesale Clothing Center (Québec) Limited (The).8181 Wilson's Sports Centre Inc.8181 Women of the Year 2,000 Beauty Salon Inc.8190 Yanow Sales Ltd.8191 Lettres patentes Letters Patent (3* partie) (Fart III) Association des aides aux malades l'Arc-en- Ciel inc.(L').-\u2022 8192 Association des Cavaliers de la Côte Nord inc.(V).8192 Association des étudiants en géologie de l'Université de Montréal.8192 Association des instructeurs de tennis du Québec inc.8192 Association des locataires des appartements Marie dc l'Incarnation inc.8192 Association des propriétaires du lac St-Sébas- tien, comté Berthicr (L-).8192 Association des propriétaires du Mont Bon Plaisir inc.8192 Association provinciale des conseillers de ventes inc.8192 Club de l'Age d'Or de Saint-Théodore de Chertsey(Le).8192 Club des aines nomades de l'Ile de Montréal (C.A.N.I.M.) (Le).8192 Club d'auto neige Castor inc.8315 Club des francs gourmets de la Tuque inc.(Le).8192 Club des loisirs du canton Percé.8192 Club de plein air de Morin Heights.8192 Comité québécois des sentiers de randonnée inc.8192 Commandair inc.8192 École de ski nautique les Intrépides.8192 Fondation les Lutins du Château.8193 Fondation Mgr.Joseph Chevalier (La).8193 Ligue des propriétaires de Grantliam-Ouest 8193 Ligue des taxis de St-Jérôme inc.(La).8193 Ligue de taxis de Val d'Or inc.(La).8193 Lovai Order of Moose (Sorel Lodge 858) Inc.8193 Morin Heights Outing Club.8192 Ordre loyal des Moose (loge 858 Sorel) inc.(L') 8193 Project Change-Services for the Elderly.8193 Seniors Nomad Club of the Island of Montreal (C.A.N.I.M.)._.8192 Services aux personnes âgées - Projet changement.8193 Lettres patentes Letters Patent avis de correction Notice of correction Constructions Armand Jeanson inc.81% Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent A.N.I.(Central) Limited.8193 Aliments Leahy inc.(Les).8193 Arbour et Vidal inc.8193 B.& R.Industries Ltd.8195 B.S.S.inc.8193 Baie St-Paul Automobile inc.8193 Brasserie Entre Pots inc.8193 Brault, Guy, O'Brien inc.8194 Calais Development Inc.8194 Centre commercial Deux Mille inc.8194 Centre commercial La Tuque ltée.8194 Chemical Financial Services Limited.8195 Club de Tennis Montcalm inc.8194 Club de squash Ville-Marie inc.(Le).8194 Coldor Chinchilla Ranch inc.8194 N t(H) QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.44 Lettres patentes Letters Patent supplémentaires Supplementary (suite) (continued) Compresseurs Gelinas inc.(Les).8194 Conseil régional des loisirs de la Rive-Sud.8194 Construction Béland inc.8194 Construction Ottamont inc.8194 Continental Financial Corporation.8194 Corporation financière Continental.8194 Deaudelin (Marcel) inc.8194 Direquair inc.8194 Dupras-Falet inc.8194 Entreprises Roch Savage ltée (Les).8194 Fermanagh Limited.8194 Fermanagh limitée.8194 Friedman (Sidney) inc.8194 Gelinas Compressors Inc.8194 Glenora Securities, Inc.8194 Honco inc.8194 Immeubles Aulhier ltée (Les) (Correction) 8316 Immeubles K.C.K.ltée.8195 Industries B.& R.ltée (Les).8195 Industries Dorion inc.(Les).8195 Inter-Rouille Vaudreuil-Soulanges ltée.8195 K.C.K.Realties Ltd.8195 Leahy Foods Inc.8193 Lemco, distributeurs d'électronique en gros ltée.8195 Maisons-mobiles Chibougamau inc.8195 Materio Deslauriers inc.8195 Matcrio Goulet (1974) inc.8195 Metal Sturo inc.8195 Ottamont Construction Inc.8194 Papier Cascades (Cabano) inc.8195 Phildar Ltd.8195 Pilote & Frères construction inc.8195 Proulx (J.A.) inc.8195 Service de distribution Richelieu inc.(Le).8195 Services financiers Chemical limitée (Les).819o Sturo metal inc.8195 Thibault (Maurice) Ltd.8195 Vaudreuil-Soulanges Inter-Putt Ltd.8195 Ville-Marie Squash Club Inc.8194 Vin Geloso inc.8195 Siège social Head office (Article 84) (Section 84) Accessoires de plomberie G & D inc.(Les).8175 Agences Sherwood inc.8173 Albert Sales Inc.8173 Aima Autmobile ltée.8173 Antagon Construction Company Ltd.8173 Arto inc.8174 Association Chevaline Pépite d'Or.8174 Assurances Claude Lafrenière inc.(Les).8174 Balta Realties Ltd.8176 Barrette & Saucier ltée.8174 Beaudi inc.8174 Béique & Sherry inc.8174 BerolLtd.8174 Berolltée.8174 Bois franc P.N.D.ltée.8174 Brault (J.B.) Holdings Inc.8174 Bureau de traduction Trans-Adapt inc.(Le).8174 Canada Chrome Furniture Ltd.8174 Capitol Automobile inc.-.8174 Cercle des femmes journalistes incorporée (Le) 8174 Champoux (F.) ltée.8174 Chibougamau Mining & Smelting Co.Inc- 8174 Clarke (A.B.) Limited.8174 Clarke (A.B.) limitée.8174 Club d'escalade de l'Estrie inc.8174 Club naturiste Adam & Eve ltée.8174 Club des pionniers du Mont Ste-Anne inc.8174 Compagnie de construction Antagon ltée.8173 Compagnie de construction Etex ltée (La).8174 Compagnie de vêtements J.G.ltée (La).8174 Conseils régionaux dc développement associés du Québec inc.(C.R.D.A.Q.) (Les).8175 Construction Béland inc.8175 Courtier provincial en alimentation (1971) inc.8175 Crown Offset Ltd.8175 Crystal Insurance Brokers Inc.8175 Dafomax inc.8175 Dallaire et Dallaire ltée.8175 Darcon inc.8175 Decolog inc.8175 Dismatinc.8175 Domaine sportif Clairval.inc.(Le).8175 Dubé (Robert) limitée.8175 Entreprises Armand Houle ltée (Les).8175 Entreprises Estérel inc.(Les).8175 Erection Breton ltée.8175 Etex Construction Company Ltd.8174 Formules commerciales Multiples ltée (Les).8177 Fredette & Malouin Tire Service Inc.8175 Furst Permanent Management Ltd.8175 G & D Plumbing Supplies Inc.8175 Gallery Construction Inc.8175 Gemscreen Advertising Ltd.8175 Genoa General Real Estate Inc.8176 Gestions permanentes Furst ltée (Les).8175 Huile Métro inc.8176 Immeubles Balte ltée (Les).8176 Imprimerie Transcontinentale inc.8176 Industries R.& L.Girard inc.(Les).8176 Instruments de musique P.A.limitée.8176 Integrated Business Forms Inc.8177 Inter-American Textile Corp.8176 Intercine Inc.(Erratum).8389 Junior League of Montreal Inc.(The).8176 Kavanagh Automobiles ltée.8176 Kennebec Homes Inc.8176 Korvette Stores Ltd.8176 Labelle Touristeir inc.8176 Laurentides Discount Housing Inc.8176 Leeds Sales Ltd.8176 Lussier (Simon) ltée.8176 M & M Merchandising and Management Consultants Inc.8176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1974, 106' année, no U 8401 Siège social Head office (Article 84) (Section 84) (suite) (continued) M.G.B.Investments Inc.8177 Magasins Korvette ltée (Les).8170 Maple Leaf Heights Inc.8176 Maxel Holdings Ltd.8176 McGill Auto Park Inc.8176 Metro OU Inc.8176 Meunier (A.) Transport inc.8176 Meunier (Aimé) inc.8176 Modem Teak House Decor Inc.8176 Motel Rendez-Vous du Lac inc.8177 Multiple Business Forms Ltd.8177 Narlenco Surplus Jobbers Ltd.8177 Orzech, Brady & Company Ltd.8177 P.A.Musical Instruments Limited.8176 Panorama Ceramics Inc.8177 Paquette & Frère, ltée.8177 Paramount Transport Ltd.8177 Pare Mille-Isles inc.8177 Paul & Eddy inc.8177 Placements M.G.B.inc.8177 Pont Mercier Shopping Centre Merchant's Association Inc.8177 Portland Realty, Inc.8177 Provincial Food Broker (1971) Inc.8175 Quincaillerie Maurice Hamel & Fils inc.8177 René Refreshment Service Inc.8177 Robert (Louis André) ltée.8177 S.T.O.P.8177 St.Lawrence Tankers Limited.8177 St.Luc Vets Taxi Inc.8177 Samivltée.8177 Service de pneus Fredette & Malouin inc.8175 Sherwood Agencies Inc.8173 Société de formules mécanographiques inc.8177 Somi inc.8177 Spangav Management Ltd.8178 Styne's Shoe Shop Ltd.8178 Styro-Plastic Ltd.8178 Styro-Plastic ltée.8178 Super marché Méthot ltée.8178 Tardif (Pierre) inc.8178 Teka inc.8178 Top Value Ltd.8178 Transcontinental Printing Inc.8176 Turcotte (Lorenzo) inc.8178 Typographie Couronne ltée.8175 United Settlement Supply Co.Ltd.8178 Val Refuse Disposals Inc.8178 Ventes Albert inc.(Les).8173 Vivax (1973) Inc.8178 Voiliers aux Quatre Vents inc.(Les).8178 Westmount Moving and Warehousing Limited 8178 CURATELLE PUBLIC PUBLIQUE CURATORSHIP Avis de qualité: Notice of capacity: Fournier, Joseph Emile.8322 Malet, Jules.8322 DEMANDE À APPLICATIONS LA LÉGISLATURE TO LEGISLATURE Estate of Charles Séraphin Rodier.8322 Estate of Sir Joseph David Rodolphe Forget.8321 Succession Charles Séraphin Rodier.8322 Succession Sir Joseph David Rodolphe Forget 8321 Westmount, cité-city.8321 MINISTÈRES DEPARTMENTS Affaires municipales Municipal Affairs Perkins, munie.(Erratum).8389 Portland-Ouest, munie.(Erratum).8389 Wakefield, partie Est, canton-township (Erratum) .8389 Institutions Financial financières Institutions compagnies Companies et coopératives And Comperatives Assurances: Insurance: Catholic Order of Foresters (Annul.).8234 Middlesex Mutual Insurance Company (Nom- Name ch.).8234 Richesses naturelles Natural Resources Revocation of mining concessions.8329 Révocation de concessions minières.8329 Terres et forêts Lands and Forests Cadastre: Cadastre: Belleau, canton-township.8324 Letellier, canton-township.8324 Letellier, canton-township.8325 Letellier, canton-township.8325 Pabos, munie.8325 Pointe-Claire, par.8325 Pointe-Claire, par.8325 Rivière-des-Prairies, par.8326 Roxton Falls, village.8326 Saint-Jean-Chrysostome, par.8326 Saint-Martin, par.(Erratum).8390 Saint-Maurice, par.8326 Saint-Sauveur, par.8327 Régie des marchés Québec Agricultural agricole du Québec Marketing Board Office des producteurs de lait fournisseurs au poste de réception et de transformation d'Henryville de la compagnie Elmhurst Dairy Ltd.(L') (Dissolution)-.8327 Office des producteurs de lait à la laiterie Magog inc.(Dissolution).^327 Office des producteurs de lait de la laiterie Shawinigan ltée (L') (Dissolution).8328 Bruneau, Herménégilde.8322 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 2, 1974, Vol- 106, No.44 8402 Régie des marchés Québec Agricultural agricoles du Québec Marketing Board {suite) (continued) Office des producteurs dc lait de la région de Sorel (L') (Dissolution).8327 RENSEIGNEMENTS SUR COMPANIES LES COMPAGNIES INFORMATION ACT Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations; A.C.M.Inc.8199 A & W Enterprises Inc.8199 Addy (Jean) Construction ltée.8199 Agfa Inc.8199 Agence de réclamations de Sherbrooke inc.(L') 8199 Agence de voyages de Hull inc.8199 Ajustements d'assurances B.E.inc.(Les).8199 All-Con Precast Products Ltd.8200 Almur Ltd.8200 Alouette Meat Inc____ .8200 Alpha Equipment Mfg.inc.8200 American General Supply of Canada (1969) Limited.8200 Ameublement St-Victor incorporé.8200 Amis du théâtre du Saguenay inc.8200 Amusement Etoile inc.8200 Andover Press Ltd.8200 Andrews-Boyd Ltd .8200 Andros Investments Limited.8200 As de Victoriaville inc.(Les).8200 Asbestos-Eastern Holdings Inc.8200 Ashdon Plastics Québec Inc.8200 Associated Merchandisers Ltd.8200 Association canadienne des distributeurs indépendants de films d'expression française (A.C.D.I.F.).8200 Association des directeurs dc théâtre inc.(L') 8200 Association des employés dc la banque d'épargne de la cité et du district dc Montréal (L') 8200 Association des employés non-syndiqués de la cité d'Outremont.8200 Association d'entraide du bas St-Laurent inc.(L').8200 Association des garçons de table de La Mauri- cieinc.8200 Association Ibéro-Canada.8200 Association des marchands de la Plaza Fusey inc.(L').8201 Association of Osteopathic and Physicians and Surgeons (Québec).8201 Association des parents des étudiants du collège d'enseignement général et professionnel Lionel Groulx inc.(L').8201 Association des propriétaires du quartier numéro Un de la ville de Gatineau inc.8201 Association provinciale des infirmiers du Québec.8201 Association récréative St-Rémi inc.(L').8201 Atelier de ballet classique inc.(L').8201 Atelier de rembourrage Girard ltée.8201 Atomic Films Productions Inc.8201 Au Chalet de la Montagne inc.8201 Au Petit Caporal inc.8201 Auberge Placide ltée.8201 Audic Science Inc.8201 Auto J.L.Lorrain inc.8201 Auto-buffet Decca inc.8201 Avel Island Development Inc.8201 B & J Sportswear Co.Ltd.8201 BM Dveing Inc.8201 B.& M.Packaging Ltd.8201 B & M.Tiles and Terrazzo Inc.8201 Barclay Overseas Sales Corp.8201 Bari Importing Company Inc.8201 Beauceville Lumber Co.Ltd.8201 Beauharnois Palace Hotel Inc.8202 Bédard (Elaine) Institute Ltd.8202 Bédard (Paul) inc.8202 Bédard (Roland) inc.8202 Bee Sportswear Ltd.8202 Bel Toy Novelty Inc.8202 Bélanger (Dominique) Construction inc.8202 Bellemare & St-Onge inc.8202 Belle-Ville électrique inc.8202 Bellcvue Tavern Inc.8202 Belmont Cleaners Ltd.8202 Benott (Ben) inc.8202 Bernard Electrique Inc.8202 Blue Seal Stables Inc.8202 Boivin (H.) Construction Inc.8202 Boudreault & Gagnon meubles inc.8202 Boulevard Surgical Clinic Inc.8202 Brais (Damien) & Fils inc.8202 Brassière Jouvence inc.8202 Breuvages Héroux inc.8202 Brière et Desrochers inc.8202 Brodeur (Laurent) inc.8202 C.I.B.C.Inc.8202 C.P.H.Mechanical Inc.8202 C.Z.Development Corp.8202 Caloillnc.-.8203 Camionneurs Unis Victoria inc.(Les).8203 Campus Drive-In & Restaurant Ltd.(The).8203 Can-Am Industrial Development Corp.8203 Caplan-Zunino Flowers Ltd.8203 Carette & Gilbert inc.8203 Caron & Morin inc.8203 Cat's Den Inc.8203 Centre d'achats Méthot inc.8203 Centre culturel dc Grand'Mère inc.8203 Centre dc loisir du lac de l'Est inc.(Le).8203 Centre de la maison moderne inc.(Le).8203 Centre national Bel-Air ltée.8203 Centre de nourriture St-Laurent inc.8203 Centre de ski Mont Shicks-Shocks inc.8203 Céramiques des monts inc.8203 Charbonncau (Pierre) Insurance Inc.8203 Charles Hôtel Inc.8203 Chassé (Jean-Louis) inc.8203 Châteauncuf Restaurant Inc.8203 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 108' année, n\" 44 8403 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Chez L.Corneli Pizza & Spaghetti inc.8203 Chichen-Itza Corporation.8203 Chomedey Caterers Inc.8203 Cie Alcarro inc.(La).8203 Cie de bois de Causapscal inc.(La).8203 Cie de gestion Lévesque ltée (La).8204 Ciné-théâtre du séminaire de Ste-Thérèse inc.(Le).8204 Club automobile Corvette (Québec) inc.(Le) 8204 Club chasse et pêche St-Luc.8204 Club civil 57 incorporée.8204 Club d'hiver de Hull inc.8204 Club Raymond inc.8204 Club social Colombien de Chicoutimi inc.(Le) 8204 Club sportif Dion.8204 Club de yacht Le Relais incorporé (Le).8204 Coinex Manufacturing Company Limited .8204 Colonia Industrial Development Inc.8204 Comité des citoyens propriétaires de Drummondville inc.8204 Comité des loisirs St-Alphonse-de-Granby inc.8204 Comité sportif d'Auteuil (Le).8204 Compagnie industrielle française inc.(La) .8204 Compagnie minière Demfontaine ltée.8204 Companons de L'Action (Les).8204 Concord-Ross Corp.8204 Conseil de bien-être du Québec.8204 Consolidated Wiping Products Ltd.8204 Construction D.M.limitée.8204 Construction Guy Villeneuve ltée .8204 Consultants professionnels (Québec) inc.8204 Continental Dinettes Ltd.8205 Copoloff Insurance Agencies Inc.8205 Corgemines limitée.8205 Corona Development Corporation.8205 Corporation de l'hôpital Ste-Thérèse-de-l'En- fant-Jésus de Fort George (La).8205 Corporation d'immeubles Eureka ltée (La) .8205 Corporation des propriétaires de taxi de la ville deLachute.8205 Credo Mining Limited.8205 Crème glacée (Gelateria Siciliana Inc.).8205 Cross Country Sales Corp.8205 De Nand Inc.8205 De Sola Mortgage Corporation.8205 Dell-Franco Inc.8205 Deschalets Electrique cie ltée.8205 Deschénes Pat & Frères ltée.8205 Desgroseillers Lumber Inc.8205 Design Technics Ltd.8205 Développement d'Arthabaska inc.(Le).8205 Développement des Deux Montagnes inc.(Le) 8205 Développements Lac-des-Monts inc.8205 Développements Lapero inc.8205 Développements Val-Alain inc.(Les).8205 Développement Victoriaville inc.8205 Dollard Hardware Ltd.8205 Domaine du ski Mont-Bruno inc.8206 Dormida Inc.8206 Drapeau (P.E.) inc.8206 Dufault & Associés inc.8206 Dumont & Duguay inc.8206 Duric limitée.8206 Durion Inc.8206 Earle Dress & Sportswear Ltd.8206 Eastern Fruit Co.Ltd.(The).8206 Ecole de karaté de Montréal inc.8206 Ecuries Argenteuil inc.(Les).8206 Editions Surboum inc.(Les).8206 Embassy Sportswear Mfg.Co.8206 Empire Milling Co.Ltd.8206 Enseignes Oméga Signs inc.8206 Ensembles Unisports inc.(Les).8206 Entreprises Albert ltée (Les).8206 Entreprises Céma inc.(Les).8206 Entreprises Dcsaulniers ltée.8206 Entreprises du domaine des lacs Raymond ltée (Les).8206 Entreprises G.A.L.ltée (Les).8206 Entreprises Grégo incorporée (Les).8206 Entreprises Horton inc.(Les).8206 Entreprises J.L.Dinel ltée (Les).8206 Entreprises Jalian inc.(Les).8207 Entreprises L.Gagné inc.(Les).8207 Entreprises Lambert inc.(Les).8207 Entreprises Lévis inc.(Les).8207 Entreprises Maisonneuve inc.8207 Entreprises nautiques de l'Ile Goyer ltée (Les) 8607 Entreprises Rivarole ltée (Les).8207 Entreprises Rouville inc.8207 Entreprises Urbaines ltée (Les).8207 Epicerie Traversy Inc.8207 Epsilon Investments Limited.8207 Equipement & prévention d'incendie Sag.ltée 8207 Etablissements Dubois ltée (Les).8207 Eve's Delicatessen & Snack Bar Inc.8207 Excel Investment Corp.8207 Expertises Shefford inc.(Les).8207 F.W.E.Stapenhorst Inc.8207 Fabien (B.) Inc.8207 Farrell Enterprises Inc.8207 Fashion Furniture Inc.8207 Fatima Construction Inc.8207 Ferma Import & Export Inc.8207 Ferronnerie Belmont inc.8207 Ferronnerie Cartier inc.(La).8207 Fleuriste 4-Saisons inc.8207 Flying Execs Associates.8208 Fontaine Bleau Associates Ltd.8208 Fratelli J Inc.8208 Fred-El Realties Inc.8208 Frontier Inn Inc.8208 G.M.L.Construction Inc.8208 Gagnon & Beaulieu inc.8208 Gagnon Sportswear Inc.8208 Gagnon/Valkus inc.8208 Gail Contracting & Mfg.Inc.8208 Gallant Fashions Inc.8208 8404 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 3, 1974, Vol- 106, No.44 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Gana Company Ltd.8208 Garage Lapointe incorporé.8208 Garde Immaculée Conception Inc.8208 Gaspex Mines Ltd.8208 Gaudreau (Louis-G.) & Fils inc.8208 Gesco limitée.8208 Giovanni Construction ltée.8208 Girard & Fils ltée.8208 Glenwood Water Services Inc.8208 Global Holdings Inc.8208 Goldstein (S.) (Canada) Ltd.8208 Grandchamp (Arthur) limitée.8208 Green (Walter) Investment Corp.8208 Greenrose Construction Corp.8208 Grégoire et cie ltée.8209 Grossiste en plomberie Idéal ltée.8209 Guardcrest Realty & Land Co.Ltd.8209 Harry's Meat Market Inc.8209 Hawkeye Equipment Co.Ltd.8209 Heart Investments Ltd.8209 Hermac Investments Ltd.8209 Homber Construction Corp.8209 Hôpital des Récollets inc.8209 Hôpital Ste-Rita inc.8209 Hôtel Beau-Site Inc.8209 Hôtel Bellevue (St-Félicien) ltée.8209 Hôtel Hovington inc.8209 Hôtels Maple-Groye inc.(Les).8209 Hôtel Président inc.8209 Immeubles avicoles ltée (Les).8209 Immeubles B.G.B.ltée (Les).8209 Immeubles Dulabec ltée (Les).8209 Immeubles La Lumière inc.8209 Immeubles Levasseur ltée (Les).8209 Immeubles Manu limitée (Les.8209 Immeubles Pelletier ltée (Les).8209 Immeubles Provencher ltée.8209 Immeubles République inc.(Les).8209 Immeubles Rola limitée (Les).8209 Immeubles St-Maurice ltée.8210 Immeubles Vanda inc.8210 Imperial Furniture Showrooms Inc.8210 Imprimerie Farnham incorporée.8210 Industrial Blue Collar Ltd.8210 Institut aéro-tech.de Montréal inc.8210 Institut Curé-Labelle.8210 Institut Familial (L').8210 Institut scientifique franco-canadien (L') .8210 Interform (Canada) Limited.8210 International Industrial Supplies Limited .8210 Investissements Midas ltée (Les).8210 Iroquois Petroleum Co.Ltd.8210 Isaballtée.8210 Island Products Company Ltd.8210 Ital Canada International Soccer Club Inc.8210 Ital Floor Finishers Co.Ltd.8210 J.J.Construction ltée.8210 J.M.Co.Ltd.8210 J.P.Motor Industries Ltd.8210 Jeune chambre de Gagnon inc.(La).8210 Jeune Chambre de Lachute inc.(La).8210 Jutes Victoria inc.(Les).8210 Keystone Estates Corp.8210 Keystone Mortgage Consultants Ltd.8211 L.G.Auto Repair Inc.8211 Lac Clair limitée.8211 Laflamme & Frère (1964) inc.8211 Lafrance (Jean P.) inc.8211 Langelier Transport limitée.8211 Lanthier & Frères limitée.8211 Lapointe (Armand) inc.8211 Lapointe (J.A.) T.V.inc.8211 L'Appel inc.\u2022.8211 Larrivée (Normand) inc.8211 Laurentian Sait Company Ltd.8211 Lavallée & L'Heureux inc.8211 Lawson Furniture Co.Ltd.(The).8211 Lecours (Jean-Louis) inc.8211 Legault (A.L.) construction ltée.8211 L'Elégante (Matane) limitée.8211 Lemiro inc.8211 Levasseur auto ltée.8211 Ligue des Laurentides « Junior B ».8211 Ligue des propriétaires du lac L'Achigan (La) 8211 Ligue des propriétaires du village des Escou- mins.8211 Lomicltée.8211 Loyer & Frères, cie ltée.8211 M.B.Coatings Inc.8211 M & G Holdings Ltd.8212 Magasin à rabais Nordic inc.8212 Maison Dury ltée.8212 Maison Morad ltée (La).8212 Maisonneuve Mines Inc.8212 Major (Armand) inc.8212 Major & Fils compagnie limitée.8212 Marché Calder inc.8212 Marché Champion inc.8212 Marché Orsainville inc.8212 Marché Ste-Lucie inc.8212 Marelle inc.8212 Marieville Furniture Mfg.Ltd.8212 Majorettes des Bois Francs (Les).8212 Marnel Enterprises Inc.8212 Maroquineries du Québec inc.(Les).8212 Marseil Corporation.8212 McKinnon Auto Electric Ltd.8212 Melville Press Limited.8212 Metro Store Fixtures Inc.8212 Metropolitan Water Filtration Inc.8212 Michaud (Guy) & Associés inc.8212 Miller Bros.Construction Ltd.8212 Mobilier Moderne (1963) ltée.8212 Mont St-Jovite inc.\u2022.8212 Montreal Human Hair Center Inc.8213 Mor-Cal Holding Corp.8213 Moriel Incorporated.8213 Motel Attache ltée.8213 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971,, 106- année, n\" U 8405 Avis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Motel Le Sommet inc.8213 Motel Pavillon Bleu inc.8213 Motel Quartier Latin inc.8213 Murray's M.& R.Enterprises Inc.8213 Myers (Lawrence) Inc.8213 N & I Dry Cleaners Co.8213 Nasa Corp.8213 Nemour (Tilford) Ltd.8213 Nical Bonbons Inc.8213 Nivoseltée.8213 Nordix limitée.8213 Nor-Sarre explorations minières limitée.8213 Nosov-Pedskalny (Québec) Ltd.8213 Notre-Dame Feed Service Inc.8213 Nu-Film Industries Ltd.8213 O.P.L.St-Mathieu.8213 Obie's Meat Inc.,.8213 Oeuvre des loisirs de Saint-Apollinaire (L') .8213 Oeuvre des terrains de jeux de Cap-Santé inc.(L').8213 Old Hickory Barbecue Machines Ltd.8213 Optima Inc.8213 Osminco Holdings Corp.8214 Otter Lake Investments Ltd.8214 Ouellet (Guy), inc.8214 Ouellet (Roger) inc.8214 Palermo Furniture Inc.8214 Panisa Development Inc.8214 Papeterie Brel limitée.8214 Parr Ventilation Ltd.8214 Parthenais Building Corp.8214 Paul & Sons Window Cleaning Inc.8214 Pavillon Biébeuf ltée (Le).8214 Pavillon Normandie inc.(Le).8214 Peak Electronics Ltd.8214 Pegi Construction ltée.8214 Perfection Plumbing and Heating Co.8214 Perriwick Trading Co.Ltd.8214 Peter Pan Pastry Shoppe Inc.8214 Pétroles Biron inc.8214 Phoenix Club (The).8214 Piekouagami Mining Inc.8214 Pierre Construction ltée.8214 Pigeon d'argile (Rimouski) inc.(Le).8214 Pilon & Fils inc.8214 Pilon (R.& G.) inc.8214 Pine Gables Nursing Home Ltd.8214 Pisciculture de Val-des-Bois inc.8215 Place Champlain Corp.8215 Place Les Ecores inc.8215 Placements B.G.M.ltée.8215 Placements Carmichael ltée (Les).8215 Placements Contreville inc.(Les) .8215 Placements Hamel ltée (Les)-.8215 Placements industriels du Québec limitée (Les) 8215 Placements Jacou inc.(Les).8215 Placements Le Gardeur inc.8215 Placements Mérici inc.8215 Placements Mobergc inc.(Les).8215 Placements Montigny inc.(Les).8215 Placements Routhier ltée (Les).8215 Placements Sifar inc.(Les).8215 Placements Terbec ltée (Les).8215 Placements Ville-Marie limitée (Les).8215 Plastic Services & Dies Ltd.8215 Plomberie Michel inc.8215 Poirier (L.) Transport inc.8215 Poulin & Rodrigue inc.8215 Princess Land & Housing Corp.8215 Pritchard (A.E.) Ltd.8215 Produits alimentaires Chantelcler inc.8215 Produits d'érables Tuque Rouge ltée.8216 Produits de mer Les Escoumins inc.8216 Produits sanitaires Fleur-de-Lys ltée (Les).8216 Prothésoral limitée.8216 Publications de Bcauharnois inc.(Les).8216 Québec Phonographs Ltd.8216 Quincaillerie Hector Durand inc.8216 R.F.Electronic Inc.8216 R & G Estates Inc.8126 R.L.Electro Machining Inc.8216 Rachmann (Peter J.) Limited.8216 Rambling Tours Inc.8216 Raymond & Jean Inc.8216 Red Rib Steak House Ltd.8216 Regal Distribution ltée.8216 Reliure classique inc.8216 Renaud & Fils inc.8216 Renil aviculture inc.8216 Renlowe Corporation.8216 Repro-Express Inc.8216 Reprox Corporation.8216 Restaurant Casse-croûte incorporée (Le)- 8216 Restaurant Le Sabre inc.8216 Restaurant Méditerranée inc.8216 Retel Enterprises Inc.8216 Richelieu Properties Inc.8217 Ridgewood Cleaning Maintenance Ltd.8217 Rival 5, 10, 15, $1.00 Stores Inc.8217 Riverview Hotel Inc.8217 Riviera Swinsuits Ltd.8217 Robert (Wilbrod) inc.8217 Robitaille (Marc) inc.8217 Roblin Enterprises Inc.8217 Rocket Petroleum Explorations Ltd.8217 Ronderosa Corporation.8217 Ropin Inc.8217 Roscdale Homes & Mortgage Inc.8217 Roy (Raymond) Inc.8217 Roy (Robert) & Associés inc.8217 St-Bruno Riding Club Inc.8217 St.Catherine's Department Store Ltd.8217 St-Hilaire (Fernando) limitée.8217 St-Michel Valet Service Inc.8217 Ste-Marie Air Service Inc.8217 Salaison Cartier inc.8217 Salons funéraires Demers ltée.8217 Salons funéraires Gauthier ltée (I-es).8217 8406 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 1974, Vol.106, No.4i A vis de dissolution Notice of Eventual éventuelle de corporations: Dissolution of Corporations: (suite) (continued) Sano Workex Ltd.8217 Scrap &Sui plus Ltd.8217 Sécurité Abc inc.8217 Sertex inc.8218 Service de constructino domiciliaire ltée.8218 Service de livraison G.Lemay inc.8218 Service dc location Fibra inc.8218 Service des loisirs Ste-Gertrude.8218 Service sanitaire S.S.inc.8218 Sherbrooke-Cavendish Corporation.8218 Sherimco incorporée.8218 Si-Bon Fashions Inc.8218 Silhouette Health Studios (No.5) Ltd.8218 Skinolnc.8218 Snowdon, Sauvé, Ltd.8218 Société financière Vendôme ltée.8218 Société de gestion Notre-Dame inc.8218 Société immobilière Bonin limitée.8218 Société immobilière Habitat ltée.8218 Société Légaré inc.(La).8218 Société de planification municipale incorporée (La).8218 Société Rialto incorporée.8218 Sogetim inc.8218 Sophia Restaurant (St.Eustache) Ltd.8218 Sorel Steak House Inc.8218 South Shore Fur & Garment Storage Inc.8218 South Shore Painting Inc.8218 Spécialités Dalvanie, cie ltée.8218 Speed-O-Set Corporation.8219 Spensieri (Liberate-) ltée.8219 Steel Flange Manufacturing Co.Ltd.8219 Stephenson Company Ltd.8219 Stern (Lou) Sales Inc.8219 Stone (Buddy) Inc.8219 Studio de détente Sauna inc.8219 Sunday Herald Publishing Co.8219 Sunset Farms Ltd.8219 Super-Power Cleaning & Maintenance Co .8219 Survival Supplies Co.Ltd.8219 Swirsky Construction Ltd.8219 Systcoms limitée.8219 Table d'hôte incorporée.8219 Talon Asbestos Mines Limited.3219 Tanohurst Investments Ltd.3219 Techno-Film Services Co.Ltd.3219 Télé-publicité inc.8219 Tessier & Tcssier incorporé.8219 Théâtre Port Cartier inc.8219 Thibeault (J.J.) & Fils inc.8219 Tiroirs à double usage limitée.8219 Toiture Mauricienne inc.8219 Top Realty Inc.8220 Tousignant (Esdras) inc.8220 Trans-Canada Uniform Co.Ltd.8220 Transport Lanctôt ltée.8220 T répanier (Jean-Paul) inc.8220 Tri-Land Investment Corp.8220 Truites laurentiennes inc.8220 Turnbull & Sons Limited.8220 U-Drive Rentals Ltd.8220 Union de famille de Ste-Jeanne-de-Chantal.8220 Vaccaro (André) Construction ltée.8220 Vahade (J.P.) Fils ltée.8220 Vendeuses automatiques Champlain inc.8220 Viau (Marcel) limitée.8220 Village Habitant inc.8220 Ville-Marie Motor Hotel Ltd.8220 Vogue Buckle inc.8220 Vosko Holdings Inc ¦ ¦ \u2022 \u2022.8220 Waterloo Arena Association Inc.8220 Waterman Canada Inc.8220 West (David) Limited.8220 Windsor Import Corp.8220 Zante Pizza Ltd.8220 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: A.& A.Investment Co.Inc.8221 A.A.C.Expresso Coffee Machines Inc.8221 Abri nucléaire de Québec ltée.8221 Aérodrome Montréal international autobus et taxis inc.8221 Agence Lumen inc.(L').8221 Ain Enterprises Inc.8221 Alliance française (St-Georges, Beauce) inc.8221 Alroc Contracting Limited.8221 Ambassadrices de Shawinigan inc.(Les).8221 Anga Investment Corp.8221 Anvil Building Corp.8222 Aqua Mining Corporation Limited.8222 Association athlétique des employés de la compagnie Norton.8222 Association des citoyens de Chambly incorporée .8222 Association des commissions scolaires du centre du Québec.8222 Association des manufacturiers de gants de la province de Québec (L').8222 Association des propriétaires de Ste-Thérèse- en-Haut.8222 Association récréative de l'imprimerie nationale (L').8222 Association sportive de Charlesbourg (L').8222 Association des taverniers du Trois-Rivières métropolitain inc.(L').8222 Atlantic Products Company Limited.8222 Atlas Development Inc.8222 Atlas Shoulder Pads of Canada Ltd.8222 Auberge Vieux-Moulin St-Romuald inc.8222 Auto-Confort R.inc.8222 BM Developments (Québec) Limited.8222 Barmart Ltd.8222 Beau Lac Construction limitée.8222 Beauce Voyages Inc.8222 Beaver Industrial Equipment Ltd.8222 Benoit (Real) excavation ltée.8222 Biorhythmic Charts of Canada Inc.8222 Bizier (M.) inc.8222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1971,, 106- année, n° U 8407 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Blanchetle & Plante limitée.8223 Bomac Building Corp.8223 Boucher (J.Edouard), ltée.8223 P.& M.Boucher inc.8223 Bray Construction Ltd.8223 Brighton Press Inc.8223 Brunet (F.) & Sons inc.8223 Brunet (Gérard) inc.8223 Buanderie de Montigny inc.8223 Buffet Laperrière inc.8223 Caba-et Aux flammes inc.8223 Camb idge Press Limited .8223 Camping & Sports modernes inc.822o Capitol Building Corporation.8223 Carbitco Ltd.8223 Cardinal Sports Inc.8223 Carlton Investments Inc.8223 Caron (Gerry) inc.8223 Cell-Rock Inc.8223 Centre communautaire de villégiature Duvernay inc.8223 Centre des loisirs de Baldwin inc.(Le).8223 Centre récréatif St-François-Xavier inc.8223 Chalets Basso inc.(Les).8223 Chalet du Tricot inc.(Le).8223 Chapire inc.8223 Chatco Inc.8224 Château Steel Corporation Ltd.8224 Chevaliers d'Iberville inc.8224 Chez Pierre & Carlo inc.8224 Cloverdale Park Tenants Association Inc.8224 Club art et danse de la région de l'Amiante.8224 Club de baseball (Les Indiens de Québec inc.) (Le).8224 Cluo des oOO.8224 Club de golf de Carleton incorporée.8224 Club nautique du lac Brompton inc.8224 Cluo St-Athanase.8224 Club sportif Amiante Indépendant inc.8224 Club des voyageurs d'autos-neige de la vallée de la Gatineau (Le) .8224 Club de Yatching d'Amos inc.8224 Comié industriel et de développement du grand St-Georges inc.(Le) .8224 Comité des loisirs de Val Mauricie inc.8224 Compagnie Belle Vue inc.(La).8224 Compagnie de construction Yvan ltée (La) .8224 Comp-Ta-Bi-Lex inc.8224 Comptoir des Intermédiaires inc.8224 Confections Laurentiennes inc.(Les).8224 Constructart Inc.8224 Constructions Rocco inc.(Les).8224 Corporation des inspecteurs, techniciens en hygiène sociale (La).8224 Corporation des sports et loisirs de Windsor.8225 Créations Heddy ltée.8225 Credo inc.8225 Cyr (R.) Construction ltée.8225 D.C.Electric Inc.8225 De Blois Construction ltée.8225 De Villiers et Associés ltée.8225 Deblyn Agencies Inc.8225 Desmarais Manufacturing Inc.8225 Développement Parc Salaberry inc.8225 Di Lillo & Grassi Ltd.8225 Distribution Provinciale inc.8225 Dochodova Investment Co.Ltd.8225 Doré (Adrien) inc.8225 Dunn (Thomas A.) Ltd.8225 Durand (Charlotte et Jean) inc.8225 Durand-Mercier limitée.8225 Duval (Gilles) inc.8225 E.C.S.Plastics Ltd.8225 E.T.Realties Co.Ltd.8225 Eastern Township Welding Inc.8225 Eastern & Western Lumber Company Limited.8225 Editions Mauriciennes inc.(Les).8225 Elida Knitting Mills Ltd.8225 Entreprises Boyer, inc.(Les) .8225 Entreprises C.Bibeau inc.(Les).8226 Entreprises Lamco ltée (Les).8226 Entreprises Montier ltée (Les).8226 Entreprises Rivard inc.(Les).8226 Entreprises Spero Andrews ltée (Les).8226 Epstein (David) Inc.8226 F.B.M.Restaurant Inc.8226 Fairton Investment Ltd.8226 Fédération professionnelle des journalistes du Québec inc.8226 Ferblanterie Canada ltée.8226 Ferme Asselin inc.8226 Five Bees Inc.8226 Fort Coulonge Driving Club (The).8226 407 McGill St.Restaurant Inc.8226 Fournel (Jean-Guy) inc.8226 Galeries du Cap ltée (Les).8226 Gazoducs Trans-Québec ltée.8226 Genty Tennis Club.8226 Germain (Yves) Construction inc.8226 Germain (Yves) & Frères inc.8226 Géroma Construction ltée.8226 Gingras (Philippe) ltée.8226 Gogo Cartage & Garage Co.8226 Gold Trading Company Ltd.8226 Golf Municipal Ancienne Lorette Inc.8226 Gosselin (Philippe) (Lévis) inc.8227 Grands travaux de Montréal inc.(Les).8227 Grandmont Bull Dozer Inc.8227 Granit Gauthier limitée.8227 Graph-Tech Inc.8227 Guilde des artistes et travailleurs alliés inc.(La).8227 Handyman Construction Co.Ltd.8227 Hartland Acceptance Corp.8227 Hemar Holdings Inc.8227 Hermes Sandwich Shop Inc.8227 Hi-Test Premier Products (Canada) Ltd.8227 Holiday Ranch Inc.8227 8408 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November S, 1974, Vol- 106.No.U Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Hollinger Associates Inc.8227 Homier (D.) inc.8227 Hôtel Champlain (La Tuque) limitée.8227 Hôtel Mont-Shefford ( 1970) limitée.8227 Hôtel Victoria (La Sarre) ltée.8227 Hôteliers de Sherbrooke inc.(Les).8227 Hy et Al Restaurant inc.3227 Poerville Meat Market Inc.3227 Immeubles de Charlevoix inc.(Les).3227 Immeuble Garand inc.8227 Immeubles Renson inc.3227 Importations C.B.inc.(Les).8227 Industries linières du Québec limitée (Les).3227 Industries Marco inc.8228 Industries Victor ltée (Les).8228 Isolations des Cantons de l'Est ltée.8228 Jardins des Cèdres inc.8228 Jardins du lac Leblanc inc.(Les).8228 Jarry Motor Corporation.8228 Jeunes chambre de Manseau inc.(La).8228 Jeune chambre de St-Augustin inc.(La).8228 Kastcl Enterprises Ltd.8228 Kelco Limited.8228 Labelle (Albert) inc.8228 Laboratoires Omand ltée (Les).8228 La course (Serge) inc.8228 Laer inc.8228 Lag inc.8228 Laiterie Clark inc.8228 Lasaie Mortgage Incorporated.8228 Latreille Gas Naturel Equipment Cie ltée.8228 Latreille (Paul) limitée.8228 Laurcntian Adjustment Bureau Ltd.8228 Lefebvre (J.O.) inc.8228 Letoh Corporation Ltd.-.8228 Liqueurs Cazanove Corporation ltée.8228 Liquid Controls Corporation (Canada) ltd.8228 I.IL- et Clément inc.8228 Loisirs de Contrecoeur inc.(Les).8229 Loisirs de l'Espérance inc.(Les).8229 Loisirs St-Luc inc.(Les).8229 Loisirs de Saint-Sauveur-des-Monts inc.(Les) 8229 Longueuil Home Improvements Ltd.8229 Lutins du Mont-Sutton limitée (Les).8229 Mt.Tremblant Holdings Corp.8229 Mahcux & Giguère inc.8229 Manoir des Rapides inc.8229 Mass Entreprises Ltd.8229 Mayer (M) Realties Inc.8229 Ménard Laundromat inc.8229 Meunerie Cowansville inc.8229 Meunerie Mobile Michaud inc.8229 Meunerie Régionale inc.8229 Mine Faucon limitée (La).8229 Minimax inc.8229 Mobile Frame Service Co.Inc.8229 Monarch Paving Co.Ltd.8229 Montreal Millwork Window Division Ltd.8229 Moon-Glo Inc.§229 Motel Rout e No.2 inc.8229 Mountainlake Investment Limited.8229 Municipal Enterprises Ltd.8229 Muralec inc.8229 N.D.G.Football Conference Inc.8230 Norencv Inc.8230 North.Shore Football League Inc.8230 Nu Cote Inc.8230 OTJ de la paroisse St-Raphaè'1-de-Jonquière inc.8230 Oeuvre des loisirs de St-Gédéon-de-Frontenac inc.(L').8230 Oeuvre des terrains de jeux de St-Etienne-des- Grès inc.(L').8230 Oeuvre des terrains de jeux du Lac Bouchette inc.(L').8230 Oeuvre des terrains de jeux de Lantier (L').8230 Oeuvre des terrains de jeux de ville Val St-Michel (L').8230 Palm Industries Inc.8230 Pan-A, Iron & Metal Corp.8230 Pantarei Inc.8230 Pasmas Inc.8230 Paul's Petroleum Transport Inc.8230 Pelletier (J.V.) ltée.8230 Pétrole J.G.Cossette inc.8230 Pharal Plastics Inc.8230 Pickering Motors Inc.8230 Placements Chomedey ltée (Les).82 0 Placements Suda inc.(Les).82 0 Plage Lebel inc.82 0 Planipromotion inc.8230 Pontiac Lions Club (The).8230 Porter Brothers Construction Ltd.- 8230 Prime Windows of Canada (Québec) Limited.8231 Property Owners Association of the Town of St.Eustache-sur-le-Lac.8231 Provincial Fruit Co.of Rouyn Que.Limited 8231 Pyequart Ltd.8231 Québec Auto Ignition Inc.8231 Québec Geneiic Drug Products Inc.8231 Québec Hoist Truck Inc.8231 Québec Steel Setting Inc.8231 Quenneville (J.T.) inc.8231 Rapid Plastics Ltd.8231 Raymond Motors Ltd.8231 Realtone Electronics Limited.8231 Remer Fur Co.Inc.8231 Rénovation Cartier inc.8231 Richelieu Acres Ltd.8231 Robat Development Inc.8231 Robinson (B.N.) & Cie ltée.8231 Rogers Housewares Limited.8231 Ron a Development Inc.8231 Rosemère Investments Inc.8231 Roy (L.G.) inc.8231 St-Bruno Horse Show Inc.8231 St-Lambert Rifle Club Inc.8231 St-Lawrence Bowmen Inc.8231 Sablec inc.8231 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S novembre 1974, 106' année, no 44 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (finite) (continued) Sabre Service Station Ltd.8232 Saguenay Construction (1961) Inc.8232 Salaison des Bois-Francs inc.8232 Salaison Ville Emard inc.8232 Salle d'accueil Domrémy-Grand'Mère.8232 Salon des arts de Shawinigan.8232 Salons Bédard inc.(Les).8232 Salon de santé de Québec inc.(Le).8232 Samson (Paul) ltée.8232 Saniphane Co.Ltd.8232 Sani-Thermo inc.8232 Schmoe Realties Ltd.8232 Schwartz (Morris) Holdings Inc.8232 Scotcher Enterprises Inc.8232 Scouts de Roberval inc.(Les).8232 Scrad Inc.8232 Sept Res Steak House Inc.8232 Serba Inc.8232 Service d'habitation Ghylor limitée.8232 Service des loisirs St-Christophe-de-Pont- Viau.8232 Service des loisirs Ste-Germaine-Cousin.8232 Sharon's Restaurant Inc.8232 Shawbridge Bakery Ltd.8232 Sirois Construction Inc.8232 Sixty-Eight Development Inc.8232 Sladen (Québec) Limited.8233 Société Marquette inc.(La).8233 Société Paul Dubord limitée (La).8233 Soudo-Meg Inc.'.8233 South.Shore Marine & Industrial Equipment Ltd.8233 Spécialités Dionne ltée.8233 Staediler (J.S.) Québec ltée.8233 Stone (Fabien) Corporation Ltd.8233 Structural Erectors Ltd.8233 Studio d'amaigrissement Forme Miracle de Thetford Mines ino.8233 Tabagie Loufar ltée.8233 Tangon inc.(Le).8233 Terrasse Thérèse inc.8233 Théâtre de L'Airel inc.(Le).8233 Thompson (Dorothy) inc.8233 Titanic Development Limited.8233 Tremblay & Tremblay Plâtriers ltée.8233 Trepero Inc.8233 Tri-Tab of Canada Ltd.8233 True-Torque Brake Company.8233 Up Rite Development Corp.of Montreal Inc.8233 Usinages de Carignan inc.(Les).8233 Val Roy Motors Inc.8233 Valeurs Concorde ltée (Les).8233 Variétés Mozart inc.8233 Viau Asphalt & Paving Inc.8234 White Cross Uniform Limited.8234 8409 Révocation de Revocation of dissolution: dissolution: Club Indien.8221 Domaine de l'Etoile inc.(Le).8221 Equipe pastorale de l'Immaculée-Conception.8221 Société historique de Drummondville.8221 Wrightville Building Supplies Co.Ltd.8221 SERVICES DE SANTÉ HEALTH SERVICES ET SERVICES SOCIAUX, AND SOCIAL Loi sur les SER VICES A CT Centre hospitalier Rouyn-Noranda (L.P.S.).8328 Sociétés coopératives Cooperative agricoles Agricultural Associations Société coopérative agricole des Bois-Francs (Fusion-Amalgamation).8328 Sociétés d'habitation Québec Housing du Québec Association Joliette, cite-city (Programme de rénovation-Renewal program).8329 Thetford Mines, cité-city (Programme de rénovation-Renewal program).8329 SOUMISSIONS TENDERS Arvida, ville-city.8363 Châteauguay-Centre, ville-town.8366 Dorval, cité-city.8361 Estrie, c.s.r.-r.s.b.8354 Mont-Joli, ville-town.8364 Montréal-Nord-North, cité-city (Correction).8372 Percé, ville-city.8369 Pierrefonds, ville-city.8356 Saint-Hyacinthe, cité-city.8352 Saguenay, c.s.r.-r.s.b.8370 Senneterre, ville-town.8360 Vieilles-Forges, c.s.r.-r.s.b.8358 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Association des enseignants catholiques de Charlevoix (Siège social-Head office).8323 Fraternité des policiers de la communauté urbaine de Montréal inc.(Nom-Name ch.).8324 Syndicat des enseignants de l'Estrie (Erratum).8387 Syndicat des producteurs de bois du comté de Labelle (Erratum).8387 Syndicat des producteurs de pommes de la région de Missisquoi et de l'Estrie (UPA) (Const.).8324 Syndicat des producteurs de volailles de la région de Nicolet (U.P.A.) (Erratum).8388 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Goods C.P.Express Limited.8380 Cie Messageries CP Limitée (La).8380 8410 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November S, 197i.Vol.106, No.U Licitation Licitation Simoneau vs Refiler.8372 Par Shérifs By Sheriffs Abitibi Abitibi Beaucage vs Laroche.8373 Gaspé Gaspé Servant vs Basque.8374 Joliette Joliette Labrodor Acceptance Corporation»»Robert.8374 Montréal Montreal Placements Pointe-Claire ltée m Colibri Construction ltée et al.8376 Québec Québec Bélanger vs Tremblay.8376 Boiteau Inc.vs Gilbert Pichette ltée.8379 Durand et al vs Larouche et al.8377 Funérarium Lacoursière ltée vs Allard, héri- tiers-heirs.8378 Gagné vs Donaldson.8379 Marchand vs C.A.Parent inc.8379 Perron et ai., w Proulx.8378 Taxes Taxes Montmagny Montmagny Calvert Fire Insurance Company vs Bernier.8375 Anjou, ville-city.Gaspé, ville-town.Saint-Laurent, ville-city 8334 8331 8330 SOMMAIRE Avis divers.8292 Caisses d'épargne et de crédit.8323-8387 Changement de nom, Loi du.8317 Commission des transports du Québec .8235 Compagnies, Avis concernant la Loi des 8155 8315-8380 Compagnies étrangères.8320-8351 Curatelle publique.8322 Demandes à la Législature.8321 Ministères.8234-8324-8329-8389 Régie des marchés agricoles du Québec 8327 Renseignements sur les compagnies.8199 Services de santé et services sociaux.8328 Sociétés coopératives agricoles.8328 Société d'habitation du Québec.8329 Soumissions.8352 Syndicats professionnels.8323-8387 Ventes: Effets non réclamés.8380 Licitation.8372 Par shérifs.8373 Pour taxes.8330 SUMMARY Applications to Legislature.8321 Change of Name Act.8317 Companies Act, Notices concerning the.8155 8315-8380 Companies Information Act.8199 Cooperative Agricultural Associations.8328 Departments.8234-8324-8329-8389 Extra-Provincial Companies Act.8320-8351 Health Services and Social Services.8328 Miscellaneous Notices.8292 Professional Syndicates.8323-8387 Public Curatorship.8322 Quebec Agricultural Marketing Board.8327 Québec Housing Corporation.8329 Québec Transport Commission.8235 Sales : Licitation.8372 By Sheriffs.8373 For taxes.8330 Unclaimed Goods.8380 Savings and Credit Unions.8323-8387 Tenders.8352 "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.