Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 16 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichier (1)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1974-11-16, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" JU GAZETTE QUÉBEC « ~* OFFICIELLE OFFICIAL DU QUÉBEC GAZETTE G3/ PTIE1 PARTIE 1 PART 1 EX.2 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8589 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazelle officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 parait le samedi matin et contientdesavis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas, l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire à midi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Québec Official Gazelle, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Québec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Quebec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Québec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Officiai PublMer S590 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 197A, Vol.106, No.16 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: S3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1) : du 1er janvier au 31 décembre, $20; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Éditeur officiel du Québec.Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that, the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Editeur officiel du Québec, Cité Parlementaire.Québec G1R 4Y7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971.106' année, n° 16 8591 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Avis de dissolution éventuelle de corporations Notice of Eventual Dissolution of Corporations Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu des articles 4.5a et suivants de la Loi des renseignements sur les compagnies, les corporations dont les noms suivent sont en défaut de produire le rapport visé par l'article 4 de ladite loi pour une année ou plus; les corporations sont en conséquence passibles de dissolution sans autre avertissement si elles n'ont pas fourni tous les rapports indiqués en regard de leur nom ainsi que les honoraires prescrits, dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to section 4, 5a and following of the Companies Information Act, the companies whose names follow, have failed to file the return mentioned in section 4 of the said Act, for one year or more; the companies are consequently subject to dissolution without further notice if they have not provided all the returns indicated opposite their names and the specified fees, within the 30 days following publication of this notice.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed A & D TEXTILES LTD.84231 A.G.R.INC.87680 A & M CONTRACT HARDWARE LTD.93134 A.M.S.CONSTRUCTION INC.83381 A.R.TRADING COMPANY LTD.89064 A.S.PROPERTIES LTD.93282 A.S.P.CONSTRUCTION INC.87919 ACADEMIE D'ARMES D'ESCRIME DU QUEBEC .83541 ACADEMIE DES GASTRONOMES DU QUEBEC 89425 L'ACTION DEMOCRATIQUE DE SALABERRY-DE- VALLEYFIELD INC.88580 ADIN DRESSES INC.91856 ADINI CORP.01148 AESCO LTEE.85781 LES AGENCES BELLE-ILE INC.91857 AGENCES CLAUDE LIMITEE.28849 AGENCE LAURENT INC.91011 LES AGENCES SAINT-VINCENT-DE-PAUL INC.34570 Montreal.1965 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal .1970 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965,1972.1973 Montreal.1966.1967.1973 Montreal.1967.1970, 1972.1973 St-Michel.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Longueuil.1966 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield .1966 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montréal.1966 et/and 1973 Montreal.1965, 1970, 1971, 1973 Montréal.1966 à,to 1973 incl.Montréal.1954 à 1973 incl.Côte-St-Luc.1973 St-Vincent-de-Paul.1956 à/to 1973 incl. 8592 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed AIDA CHESTERFIELD INC.88581 LES AIGLES D'ALMA INC.89426 AIR-FLO SYSTEMS SERVICES INC.87096 AIRPAK LIMITEE.82328 ALIBON LIMITEE.87681 ALL STAR SALES COMPANY LTD.84369 ALLAIRE AUTO LOCATIION INC.91859 ALLARD & LAUZON LTEE 84791 ALOUETTE ACCEPTANCE CORPORATION 86542 ALPHA DEMOLITION INC.87923 ALPINE INVESTMENTS LTD.83387 ALUMINUM HOME PRODUCTS INC.90628 AMEUBLEMENT G.& N.LTEE.88582 LES AMEUBLEMENTS POULIN & FRERE LIMITEE 83237 AMIGA INC.90539 AMUSEMENT ROYAL LIMITEE.83059 ANDBERG ENTERPRISES INC.89756 ANIMAL KINGDOM PET SHOPPES & SUPPLY CO.LTD.87682 ANKER CONSTRUCTION LTD 91750 ANTED CORPORATION.83746 A-l IRON & METAL CO.LTD.87624 APPARTEMENTS DENYS INC.93032 AQUA VITA INC.82206 L'AQUEDUC DE STE-MARTINE INC.218240 AREO FEU (1969) CANADA LTEE 115857 St-Pierre.Alma.Montreal.St-Lazare.Montréal.Duvernay.Chibougamau.Chibougamau .Montreal.Montreal.Mount-Royal.Montreal.Rosemère.St-Vincent-de-Paul Montreal.Val d'Or.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Montreal.Sept-Iles.St-Alexandre.Ste-Martine.Ville D'Anjou.1966 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1965 à/to 1973 incl.1966, 1967.1972, 1973 1965, 1966, 1968, 1970 à/to 1973 incl.1971 et/and 1973 1967 à/to 1973 incl.1973 1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1973 1965, 1969.1971 à/to 1973 incl.1973 1970 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1973 1965 à/to 1973 incl.1967, 1971 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1954, 1960 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8593 Nom de la compagnie Name of the Company ARGENCE HOLDINGS INC.90889 ARLINGTON LANE CORP LTD.89004 ROSS M.ARNOTT INC.89191 ART AINSCOW INC.83832 ASSOCIATED PRODUCTS OF AMERICA (QUEBEC) LTD.87172 L ASSOCIATION DU BASEBALL DE ST-HENRI INC.84055 ASSOCIATION DES CENTRES DE SKI DES LAURENTIDES INC.82153 L'ASSOCIATION DES CHEMINS DESCHAILLONS- FORTIERVILLE 24556 ASSOCIATION DES COMMERCES DE CHARLESBOURG INC.91766 ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU DISTRICT DE JOLIETTE INC.83064 ASSOCIATION DES ETUDIANTS DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES 87297 L'ASSOCIATION DES LOISIRS ST-ROSAIRE DE POINTE- GATINEAU 90894 ASSOCIATION DE NATATION BRIARWOOD INC.85862 L'ASSOCIATION PARENTS-MAITRES DE L'ASSOMPTION DE NOTRE-DAME 84160 ASSOCIATION PARENTS ET MAITRES (SECTION ELEVES SOUS-DOUESf REGIONALE MAISONNEUVE 87173 ASSOCIATION REGIONALE DES RESTAURATEURS DE MAGOG INC.83393 ASSOCIATION DES RESTAURATEURS SAGUENAY-LAC-ST- JEAN 84054 ASSOCIATION DE SIGNALISATION MUNICIPALE DU QUEBEC 83066 L'ASSOCIATION DES SKIEURS ET CAMPEURS D'ABITIBI INC.88269 L'ASSOCIATION SPORTIVE DE ST-MAJORIQUE INC.89957 LES ATELIERS MAISONNEUVE LIMITEE.26559 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1973 Montreal.1966, 1967, 1971 a/to 1973 inel.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 et/and 1973 Montreal.1966, 1971, 1973 Montréal.1965, à/to 1968 incl.1972, 1973 Ste-Agathe-des-Monts.1966, 1967, 1972, 1973 Fortierville.1952 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1966 à/to 1973 incl.Joliette.1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Pointe-Gatineau .1966 à/to 1973 incl.Pierrefonds.1965 à/to 1967 incl.1972.1973 St-Hyacinthe.1965, 1967, 1972.1973 Chomedey.1966 à/to 1973 incl.Magog.1965 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1965 à/to 1973 inçl.Montréal.1973 Barraute.1971 à/to 1973 incl.St-Majorique.1967, 1970 à/to 1973 incl Montréal.1953 à/to 1973 incl. 8594 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1071.Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed ATLAN INDUSTRIES LIMITED.87515 ATOLE INC.90098 ATOMIC TRANSPORT INC 88892 ATWATER SERVICE CENTRE INC.84059 AUBE & ASSOCIES INC.91499 L'AUBERGE DES JEUNES (MONTREAL) .118002 AUSTRIAN SOCIETY SOCIETE AUTRICHIENNE.46063 AUTO BOULEVARD ST-MARTIN INC.84279 AUTO CLUB GRANBY INC.88054 AUTO-CAM PNEUS & ACCESSOIRES INC.91018 AUTOMOBILE ACCEPTANCE CORPORATION LIMITED.32991 AVRITH BUILDING CORPORATION.1118-5493 AZURE INVESTMENT CORPORATION 91020 B.A.P.INVESTMENT CORP.85028 B.S.A.HARDWARE LTD.84681 BAKERS SHOES INC 87685 BANTAM TOGS INC.82397 BAR SALON LE BIVOUAC INC.92263 BARKO INC 90680 BARLAND LUMBER CORP 90895 L.P.BARRETTE & FILS LTEE.85438 BARRY & BO.NET LTD 83548 BAVARIAN INN INC.211122 EDOUARD BEAUCHESNE INC.83246 BEAUHARNOIS AUTOMOBILE INC 92435 Lachute.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal-Nord.Montréal.Montreal.Chomedey.Granby.Montreal.Joliette.Montreal.Montreal.Outremont.Montreal.Montreal.Montieal.Montréal.Pointe-Claire.St-Laurent.Berthierville.Montreal.Montreal.Sainte-Julie.Beauliarnois.1966 à/to 1973 incl.1966 et/and 1973 1973 1965 à/to 1973 incl.1966, 1968 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1959 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1973 1966 et/and 1973 1955, 1961 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966, 1968.1969.1971 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1970 incl.1972, 1973 1965 à/to 1973 incl.1966, 1971 à/to 1973 incl.1966, 1968 à/to 1973 incl.1966 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.1965, 1972, 1973 1965, 1967 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1966, 1971 à/to 1973 incl.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974.106- année, n° 46 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits A'ame o/ the company Address Returns not filed BEAUMARCHE INC.Montreal.1971 à/to 1973 incl.92436 BEAUMONT TRANSPORT INC.Beloeil.1972 et/and 1973 87104 BECHAUD NETTOYEURS LTEE.St-Jérôme.1970 a/to 1973 incl.86429 ART BEDARD & SON LTD.Beaconsfield.1971 à/to 1973 incl.ACHILLE BELANGER INC.La Macaja.1965 à/to 1973 incl.86430 BELLA ROSA CONSTRUCTION INC.Montreal.1966, 1968 à'to 1973 incl.86896 BELLE-AUTO INC.Amos.1971 à/to 1973 incl.8*686 BELLEVUE CONSTRUCTION INC.Pierrefonds.1968 à/to 1973 incl.83250 BELMONT MANAGEMENT CORP.Montreal.1973 93036 A.BELSKY INC.Montreal.1966, 1967, 1970 à/to 88062 1973 BENOIT & FILS LTEE.St-Laurent.1965.1968 à/to 1973 incl.BERNCO ENTERPRISES LTD.Côte-St-Luc.1966 à/to 1973 incl.87179 J^BERTHEL (1965) INC.Buckingham.1965 et/and 1973 LA^BIBLIOTHEQUE DE BARRAUTE INC.Barraute.1965 à/to 1973 incl.BIG PINE FISH AND GAME CLUB INC.Montreal.1973 88063 B0898TO 1973 incI.93295 BLUE STAR PAPER CONVERTER LTD.Montreal.1973 918/5 B£ÏÏ;Y TERRAZO \"MITEE.Chicoutimi-Nord.1966,1967,1973 82160 BOISSONNEAULT INC.Victoriaville.1967 à/to 1973 incl.93296 BOISVERT ELECTRIQUE CO.LTD.Windsor.1966, 1971 à/to 1973 incl.90632 £2M.BARDIER * FILS LTEE.Magog.1968 à/to 1973 incl.88064 BONAM INVESTMENT INC.Montreal.1966 à/to 1973 incl.89010 8596 QUÉBEC OFFICIAI.GA'/.ETTE, November 16, 1971, Vol.106.No.16 Nom de la compagnie a'amc of the company BONAVENTURE DETAILING LTD.84377 BOUCHARD & BOUCHARD LTEE.34428 EMILIO BOUCHER LTEE.89326 CONRAD BOULA Y & FILS INC.85507 GILLES BOURDEAU INC.92055 Y VON BOURGEOIS PEINTRE LTEE.87687 BROADACRES LTD.86619 JOHN N.BROCKLESBY EQUIPMENT AND SUPPLY COMPANY LIMITED 91514 BROME COUNTY RURAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 83409 BRUJOHN PROPERTIES LTD.90550 BRUNET & PARE INC.91878 GLEN BURN PROPERTIES LTD.87632 BUSINESS FORMS UNLIMITED INC.84378 THE BUS-STOP CIGAR STORE INC.85872 C.A.G.R.HOLDINGS INC.86754 C.B.S.BUILDERS INC.86435 C.G.METAL LTEE.87106 CM.AUTOMOTIVE INC.91880 CM.SPORTS INC.91702 C.M.T.ENTERPRISES LTD.63555 CAFE REGENT (1965) INC.88070 CALBO INC.84255 LES CALCAIRES NEUVILLE INC.88603 CALGA INC.82374 CAMBROTT IMPORT LTD.91703 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1965 à/to 1967 incl.1970, 1971.1973 St-Rédempteur.1956 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1966, 1967, 1972.1973 St-Hyacinthe.1973 Lasalle.1966 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1966 à/to 1968 incl., 1972, 1973 Montreal.1971 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Knowlton.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967, 1972, 1973 Montreal.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Châteauguay-Centre.1965, 1969, 1973 Levis.1966, 1967.1972, 1973 Salaberry-de-Valleyfield.1973 Ste-Thérèse.1966,1967,1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1968, 1973 v'e\"lun.1955 à/to 1973 incl.St-Marc-des-Carrières .1966 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8597 Nom de la compagnie Name of the company CAM-CRAFT LTD.89666 CAMEO IMPORTERS LTD.91883 CAMO FURNITURE INC.102371 CAMP RICHELIEU QUATRE SAISONS INC.92000 LE CAMP VAL-HELENE INC.85293 CAMPBELL & MACDONALD MOTOR SALES LTD.82168 CANADIAN PHOENIX STEEL & PIPE (QUEBEC) LTD.88711 CAP METAL INC.224564 CAPITOL FUR COMPANY.117337 G.A.CARBONNEAU LIMITEE.89669 CAREST INC.83085 LE CARNAVAL DES NEIGES DE ST-BRUNO INC.88282 CAROUSEL SALES INC.89202 CARTONNERIE DU GRAND PORTAGE INC.136571 LES CAVALIERES ET MAJORETTES DE COTEAU-STATION INC.84801 CENTENNIAL CELEBRATION CHILDREN'S VILLAGE.87189 CENTRAL PROPERTIES LTD.84075 LE CENTRE DE L'AGATE ET DE L'ARTISANAT « ORALU » INC.92273 CENTRE D'ART DE ST-HYACINTHE INC.90906 CENTRE RECREATIF D'IBERVILLE INC.85989 CERAMIQUE BRIERE ET FILS INC.83092 CERTA ETANCHEITE INC.91314 EUGENE CHARBONNEAU & FILS LTEE.88608 PAUL E.CHARBONNEAU INC.83617 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1973 Montreal.1972 et/and 1973 Montreal.1968, 1969, 1972, 1973 Ste-Thérèse.1970, 1£72, 173 Rimouski.1965 à/to 1973 incl.Lachute.1973 Montreal.1973 Trois-Rivières.1964 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Laval.1973 Mont-Tremblant.1965 à/to 1973 incl.St-Bruno-de-Montarville.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1972 et/and 1973 La Station du Coteau .1965.1968, 1969, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968 à/to 1973incl.St-Hyacinthe.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Iberville.1965 à/to 1973 incl.Fabreville.1965, 1966, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1969 et/and 1973 Montréal.1966, 1967, 1970 à/to 1973 incl.Montmagny.1965, 1970 à/to 1973 incl. s.-,!)s QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Z.CHARBONNEAU LTEE 84485 ALBERT CHARRON CONSTRUCTION LIMITEE.86789 CHARTERED ESTATE PLANNING CORPORATION .86764 LES CHAUFFAGES ELECTRIQUES M.& H.INC.S62S2 CHEZ CORN ELI PIZZA ci SPAGHETTI INC.S4258 JACK W.CHIVERS & ASSOCIATES LTD.86766 CHOQUETTE AUTOMOBILE INC.S4488 CHROMAR INDUSTRIES CO.LTD.S7110 LA CIE ALMAR LTEE.87009 CIE DE BOIS DTVRV LTEE.89206 LA CIGOGNE (PRE-NATAL) INC.87011 CIMCO (QUEBEC) LIMITED.88076 CINE CANNES INC.92449 CITY & SUBURB INVESTMENTS INC.82000 CITY WAREHOUSING LTD.92167 CLASSY BELT (1965) INC.88077 CIRCLE SERVICE CENTER INC.84079 CIRCLE WALLPAPER & PAINT INC.84383 CITY & DISTRICT LAND & INVESTMENT COMPANY 206213 CLEARVIEW ESTATES INC.87732 LE CLUB DES AMIS DE LA CANADIENNE INC.90240 CLUB AQUATIQUE ST-FRANÇOIS .Salaberry-de-Valleyfield.87112 Montréal.Hull.Montreal.Montréal.Montréal-Nord.Montréal.Cowansville.Montréal.Trois-Rivières.Ste-Agathe des Monts .Rimouski.Montreal.Montréal.Dorval.Montréal.Montreal.Montreal.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.CLUB D'ARCHERS DU SAGUENAY INC.87536 CLUB AUTOMOBILE MARAUDEUR DU QUEBEC INC.92650 CLUB AUTOS-NEIGE D'ARGENTEUIL.93128 Chicoutimi.Laval.Canton de Chatham 1965, 1968, 1972, 1973 1966, 1971 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1968, 1971 à/to 1973 incl.1965 et/and 1973 1969, 1971, 1973 1971 à/to 1973incl.1966 à/to 1973 incl.1973 1966 à/to 1973 incl.1968, 1971, 1973 1970 à/to 1973 incl.1973 1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1967 incl.1971 à/to 1973 incl.1932 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1972, 1973 1966 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1973 1966 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1967, 1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1971,, 106' année, n° 16 8599 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed St-Gabriel-de-Brandon.1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Roberval.1958 à/to 1973 incl.Montréal-Nord.1965, 1970 à/to 1973 incl.Warwick.1966 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1954 à/to 1973 incl.Ste-Marie-de-Beauce .1965.1966, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Cowansville.1966 à/to 1973 incl.Port-Alfred.1964 à/to 1967 incl., 1969 à/to 1973 incl.Arvida.1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Cadillac.1966, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Matane.1973 Lemoyne.1973 Pont-Viau.1965, 1966, 1968, 1970 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965.1966.1968 à/to 1973 incl.Drummondville.1965 à/to 1973 incl.Lac-Connelly.1964 à/to 1966 incl., 1969 à/to 1973 incl.Rivière Bleue.1968 à/to 1973 incl.Thetford-Mines.1966 à/to 1973 incl.Montmagny.1966 à/to 1973 incl.Hemmingford.1965 et/and 1973 Nom de la compagnie Name o] the company CLUB AUTO-NEIGE ST-GABRIEL.89182 CLUB DE CHASSE ET PECHE WATERLOO INC.84493 CLUB GEORGES ETIENNE CARTIER INC.42354 LE CLUB DE HOCKEY LES CASTORS DE MONTREAL-NORD INC.85882 LE CLUB DE HOCKEY « LES ETOILES DE WARWICK ».88055 LE CLUB DE HOCKEY « LES TROIS-RIVIERES » LIMITEE.31357 LE CLUB DE HOCKEY STE-MARIE-DE-BEAUCE INC.82070 LE CLUB DE HOCKEY VICTORIA INC.89460 CLUB DES JEUNES.82579 CLUB KIWANIS D'ARVIDA INC.89210 CLUB LA RELACHE INC.86102 CLUB LIONS DE CADILLAC INC.92281 CLUB MAGOG HOME OWNERS ASSOCIATION.92282 CLUB MATANAUTO INCORPORE.83540 CLUB DES MOINS JEUNES INC.92169 CLUB MUSTANG DE MONTREAL INC.84693 CLUB DE NATATION DE QUEBEC INC.86554 CLUB OPTIMISTE DE TROIS-RIVIERES INC.86773 CLUB DE SKI LES INTREPIDES.82781 CLUB DE SKI NAUTIQUE DU LAC CONNELLY INC.78952 LE CLUB DE SKI DE RIVIERE-BLEUE, INC.82217 LE CLUB SOCIAL DES OUVRIERS RETRAITES D'ASBESTOS CORPORATION LIMITED 87013 CLUB SPORTIF AU DOMAINE DU GOLF INC.87695 CLUB SPORTIF & CHAMPETRE DE HEMMINGFORD .86104 8600 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1974.Vol.106.No.46 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed CLUB SPORTIF DE L'ESPLANADE INCORPORE.68131 CLUB DE TENNIS SEPT-ILES INC.232553 LE CLUB DE TIR D'EASTMAN INC.110470 LES COIFFEURS CREATEURS CANADIENS INC 88080 LE COLLEGE FRANÇAIS (1965) INC.85306 LE COMITE DES FETES DES SOCIETES SAINT-JEAN-BAPTISTE DE SAINT-JEAN INC 91534 COMITE DES LOISIRS DE BETANIE.90146 LE COMITE DES LOISIRS DE LA DURANTAYE, INCORPOREE 86448 COMITE DES LOISIRS ST-CYRILLE-DE-WENDOVER INC.90556 COMITE DES LOISIRS DE STE-VICTOIRE DE SOREL INC.91691 COMITE 67 VAUDREUIL SOULANGES 92170 LE COMITE TOURISTIQUE MARIA-CHAPDELAINE INC.84089 COMMISSION DU 10e ANNIVERSAIRE DE TRACY INC.227495 COMMISSION DES PARCS DE WINDSOR INC.88404 LA COMPAGNIE A.B.CARAVANE LIMITEE.89213 LA COMPAGNIE DES ARTS DE ST-JEAN INC.91769 LA COMPAGNIE DE BOIS HURRICANE LTEE.85640 LA COMPAGNIE BONNE HUMEUR LTEE.83097 COMPAGNIE DE CONSTRUCTION NAULT & FRERES LIMITEE 89572 COMPAGNIE DE FABRICATION SUR COMMANDE DE PINCOURT LTEE 85451 LA COMPAGNIE GASPESIA RIMOUSKI LIMITEE.89023 LA COMPAGNIE DE GESTION GEMAR LTEE.85641 LA COMPAGNIE MINIERE LEOMARC LTEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE) 91770 Aima.1965 à/to 1973 incl.Sept-Has.1962.1964 à/to 1973 incl.Eastman.1969 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Saint-Jean.1966 à/to 1973 incl.Bétanie.1966 à/to 1973 incl.La Durantaye.1973 St-Cyrille-de-Wendover .1966.1967, 1969 à/to 1973 incl.Ste-Victoire.1973 Dorion.1966 à/to 1973 incl.Péribonka.1967, 1968.1970 à/to 1973 incl.Tracy.1964, 1965, 1967 à/to 1973 incl.Windsor.1966 et/and 1973 Trois-Rivières-Ouest .1966 à/to 1973 incl.St-Jean.1966, 1970 à to 1973 incl.St-Côme-de-Kennebec .1965 à/to 1967 incl., 1969.1971 à/to 1973 incl.M agog.1973 H\"\".1966 à/to 1973 incl.P'ncourt .1965 et/and 1973 Rimouski.1966 à/to 1973 incl.Duvernay.1965 à/to 1973 incl.St-Jérôme.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974.106' année.n° 46 8601 Nom de la compagnie Name of the company COMPAGNIE DE PRETS J.N.LIMITEE.82220 LA COMPAGNIE R.HAMEL LIMITEE.85642 LA CONFRERIE INTERNATIONALE DES CHAPEAUX RONDS DIVISION DU CANADA 85309 CONGRESS OF CANADIAN DAREDEVILS (EASTERN) LTD.29653 LES CONSTRUCTIONS DIONNE & DUVAL INC.85885 LES CONSTRUCTIONS MONT ST-HILAIRE LTEE.85804 LES CONSTRUCTIONS MORMANDIN LIMITEE.87699 LES CONSTRUCTIONS DU PLATEAU INC.90116 LES CONSTRUCTIONS STEPHANE LTEE.91320 CONTINENTAL (QUEBEC) RENT-A-CAR LTD.87641 COOPER AUTO PARTS INC.91216 CORINA SALES & SERVICE LTD.87701 CORONET CONSTRUCTION CO.LTD.89342 LA CORPORATION D'AMENAGEMENT DE LA POINTE ET DE LA RIVIERE-DU-LOUP 87116 LA CORPORATION DES ANCIENS DU SEMINAIRE DES TROIS-RIVIERES 90913 CORPORATION BEAU VALLON LTEE.90386 CORPORATION LEOPOLD ROY LTEE.88182 RUDY COTE INC.87949 J.COULLOUDON G.HAYEUR & ASSOCIES INC.82224 COULONGE CONSTRUCTION INC.86047 ED.COUTURE AUTO INC.86631 LES COUVRE-PLANCHERS M-G INC.89215 CREDIT SOREL INC.83414 CRISTAL RESTAURANTS INC.89779 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Jacques-Cartier.1966 à,'to 1973 incl.Malartic.1967, 1969 à/to 1973 incl.Outremont.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1954 à/to 1973 incl.Granby.1965, 1967 à/to 1973 incl.St-Hilaire.1965 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Laval.1966 et/and 1973 Charlesbourg.1966 à/to 1970 incl.1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1970 à/to 1973incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1971 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1966, 1972, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Clerval.1967, 1968, 1970, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1971 à/to 1973 incl.Lorraine.1966 à/to 1973 incl.Fort-Coulonge.1965 à/to 1973 incl.East-Angus.1973 Montréal-Nord.1966 à/to 1973 incl.Sorel.1965,1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967, 1971 à/to 1973 incl. S602 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 36.1974.Vol.106.No.46 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed D & G CONSTRUCTION LTEE 84269 D.& S.DISTRIBUTORS INC.91994 DAM LAKE IMPROVEMENTS ASSOCIATION 92148 DAMI LIMITEE.88523 DARLINGTON INVESTMENT CORP 86777 DENIS DE JORDY SPORTS INC.S7704 DELONG REAL ESTATE INC.83280 DELPRO CORPORATION.84814 DESCO & MARBRE INC.85713 CLAUDE DESMARAIS INC.91221 DESRA INC.84511 DETROIT CONSTRUCTION & CO LTD.90388 DEVELOPPEMENT DU LAC VALLEE INC.83626 LES DEVELOPPEMENTS STONEHAM INC.89993 DEVELOPPEMENT TUNNEL INC.86558 DIRA HOLDING CORP.85891 DIPLOM ELECTRIC CO.LTD.86000 DIPLOMAT DRY CLEANING & SHIRT LAUNDERERS INC.90763 LES DISQUES ECHO INC.85456 DISTRIBUTEURS DOLLARD INC.85318 THE DISTRICT OF BEDFORD SOCIETY FOR ADVANCEMENT OF WELFARE SERVICES 69555 DISTRICT REALTIES INC.47317 DOMAINE ILE DE FRANCE LTEE .86454 DOMAINE LAC ARGENTE INC.84906 DOMAINE LAC EDDY INC.90391 Bois-des-Filiion.1965, 1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1970 incl.1972.1973 Perkins.1967 à/to 1969 incl.1973 Drummondville.1972 et/and 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Hyacinthe.1971 à/to 1973 incl.Hull.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1972 et/and 1973 Quebec.1973 La Tuque.1973 Charlesbourg.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1973 Montréal.1965 à/to 1973 incl.Stoneham.1966 à/to 1973 incl.Beauport.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1966, 1968, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967à/to 1973 incl.Cowansville.1964 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1959 à/to 1973 incl.Montréal.1965, 1970 à/(o ]973jncl.St-Jér6me.1965 à/to 1973 incl.Ste\"Ad;'le.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1C, novembre 1971, 106' année, n° 16 8603 Nom de la compagnie Name of the company DOMAINE MARQUIS DE TRACY INC.91074 DOMAINE MONT-JOLY DU LAC PAUZE INC.90560 LE DOMAINE DES PINS D'ARGENTEUIL INC.86150 DOMAINE VERNOIS INC.90475 JEAN D'ORLY (1965) INC.85658 DORVAL DELICATESSEN (FAIRYTEW) LTD.85319 LE DOT ROUGE INC.90017 J.DUFRESNE ASPHALTE LTEE.92074 DUGUAY DRY WALL LTEE.83764 DUNNE HOLDINGS COMPANY LIMITED.83765 DUQUETTE AUTO LIMITEE.236514 DUVERNAY TERRASSEMENTS (TROIS-RIVIERES-OUEST) INC.84816 E.M.M.LIMITEE.86294 EASTERN BUSINESS FORMS INC.90127 EASTERN DIAL LTD.87958 EASTERN INDUSTRIAL CONSULTANTS LIMITED.33112 ECOLE SUPERIEURE DE BOUCHERIE & CHARCUTERIE INC.89347 LES ECURIES EPONA INC.87218 EDIFICE MARICO INC.82236 LES ELANS DE PRINCEVILLE NO 495 INC.86788 ELEVEN C'S BUILDING INC.92649 ELK INVESTMENT CORP.32858 ELRON REALTIES LTD.34433 EMBALLAGE DU QUEBEC INC.86642 L'Assomption.1971 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Tracy.1966, 1967, 1972, 1973 Ste-Thérèse-Ouest.1966, 1971 à/to 1973 incl.Lachute.1965 et/and 1973 Saint-Jean.1966, 1968 à/to 1973 incl.Clermont.1965, 1967, 1972, 1973 Dorval.1965 et/and 1973 Montréal.1973 Laval.1966 et/and 1973.Montreal.1965, 1966.1973 Hull.1965 à/to 1967 incl., 1971 à/to 1973 incl.Ormstown.1969 à/to 1973 incl.Trois-Rivicres-Ouest .1965 à/to 1968 incl-, 1970 à/to 1973 incl.Québec.1967 et/and 1973 Ville d'Anjou.1969 à/to 1973 incl.St-Laurent.1972 et/and 1973 Montreal.1955 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1967, 1970 à/to 1973 incl.Cap-de-la-Madeleine____ 1973 Chicoutimi.1965 à/to 1970 incl., 1973 Princeville.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1970, 1972, 1973 Montreal.1955 à/to 1973 incl.Montreal.1956 à/to 1973 incl. 8604 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.£6 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed EM MAR BUSINESS CONSULTANTS LTD.82238 EMPRESS JEWELLERY INC.87420 ENGRAIS ORGANIQUES DE CANDIAC LTEE.85521 LES ENTREPOTS SIMARD INC.83827 LES ENTREPRENEURS EN PLOMBERIE & CHAUFFAGE DE L'ESTRIE E.P.C.E.LIMITEE.83422 LES ENTREPRISES BEAUVAIS INC.84841 LES ENTREPRISES BONNE ENTENTE INC.91781 ENTREPRISES CARTIER-LAURIER INC.87712 LES ENTREPRISES ELAN INC.88098 LES ENTREPRISES GEVERS LTEE 85327 LES ENTREPRISES JACHA INC 85903 LES ENTREPRISES DU LAC TREMBLANT INC 83638 LES ENTREPRISES LAGUE LTEE.89350 LES ENTREPRISES ME.BEAUBIEN INC.86,91 LES ENTREPRISES MADOR INC.91329 ENTREPRISES MANICOUAGAN INC.85526 LES ENTREPRISES OLGUI LTEE 91545 LES ENTREPRISES ROLLAND JOYAL & FILS INC.91615 LES ENTREPRISES SECURITE INC.86466 LES ENTREPRISES THOMAS INC 83863 ENTREPRISES VILLENEUVE INC 86565 EPICERIE FRONTENAC LIMITEE.83768 EQUITY INVESTMENT CORP.85668 ERIKA'S MFG INC.88623 ESEF CONSTRUCTION LTD.90Ô08 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1967, 1973 Candiac.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Bedford.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montréal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Hull.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1972 et/and 1973 Montréal.1973 Ste-Thérèse.1965, 1967 à/to 1973 incl.Mont Tremblant.1965 à/to 1973 incl.Farnham Centre.1966.1967, 1969, 1973 Waltham.1966 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Lauzon.1966 à/to 1973 incl.Hauterive.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1968, 1971 à/to 1973 incl.Yamaska.1973 St-Jérôme.1965, 1972, 1973 Magog .1973 Montréal.1973 Chicoutimi.1965 à/to 1970 incl., 1972, 1973 Montreal.1973 Montreal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.i969 et/and 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8605 Nom de la compagnie Name of the company ESTEEM CONSTRUCTION INC.92180 ETABLISSEMENT SIDERURGIQUE IVANIER LTEE.84714 C.ETHIER INC.24500 EUROPA DIESEL SERVICES INC.89100 EXCEL CONSTRUCO LTEE.88103 F AW CLEANERS INC.83433 LA FANFARE DE ST-ROMUALD D'ETCHEMIN INCORPOREE 33248 FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE 91601 FENETRES VENT-O-MATIC, LTEE.97416 FERRARA BROS.PROVISIONS CO.90483 LES FESTIVITES DE LA TRAVERSEE INTERNATIONALE DU LAC ST-JEAN LTEE 91920 FIESTA BAR-B-Q INC.85071 FINE BAKERY (ROSEDALE) LTD.86302 FLEETWAY TRUCK CENTRE LTD.85814 FLEUR DE LYS DISCOUNT MART INC.86007 FLEUR DE LYS MOTOR SALES LTD.91340 FLEURY ELECTRIC INC.89476 FLEXOLITE ENTERPRISES LTD.88188 FOURRURES GILLICK LTEE.27273 FOYER DE FRAMPTON.90399 FOYER NOTRE-DAME DE LAPRAIRIE INC.84931 FOYER NOTRE-DAME DE L'ENFANT (SHERBROOKE).84126 GAFFNEY QUEBEC LIMITED .85816 LEON GAGNON INC.84932 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1966, 1970, 1973 Richelieu.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1952 à/to 1973 incl.East-Angus.1966, 1968 à/to 1973incl.Sillery.1966, 1970à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.St-Romuald-d'Etchemin.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Jude.1967, 1968, 1972, 1973 Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Alma.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1967 incl.1973 Montreal.1966 et/and 1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1953 à/to 1973 incl.St^Edouard-de-Frampton 1966 et/and 1973 La Prairie.1965 à/to 1969 incl.1973 Sherbrooke.1965 à/to 1973 incl.Dorion.1965 à/to 1973 incl.Ragueneau.1965, 1967 à/to 1973incl. 8606 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1971, Vol.106, No.16 Nom de 1 a compganie Name of the company GANTERIE AUCLAIR INC.85817 GARAGE J.A.RATELLE INC.2606S GARAGE MENARD INC.85463 GARAGE PAUL DUMAS LTEE.85818 GARAGE ROLLAND FORTIER LIMITEE.87029 GARAGE SMITH INC.87228 LA GARDE NOTRE-DAME DE FATIMA DE JONQUIERE INC.84945 GESCOMONT INC.85339 GESPHAR LTEE.88304 KEN GIL CONSTRUCTION LIMITED.84729 GLACE CRISTAL LTEE.91790 GLADO INCORPOREE.84133 GLENHAR CONSTRUCTION CO.91439 GLOBAL SURPLUS INC.89240 GLOBUS FLORESCENT INC.91345 GOLF DE MALARTIC INC.S5530 GORDON MINER LIMITED.84845 GOSSELIN CONSTRUCTION INC.90401 GRANBY AVIATION INC.86469 GRANDE COTE GARDENS INC.87558 .LA GRANDE TOURNEE INC.83440 GREENFIELD PARK PUBLISHING LTD.92192 .GRENAT INC.82332 LA GRENOUILLE ET LE BOEUF DE MONTREAL INC 84549 GRESHAM INDUSTRIAL INKS LIMITED 89484 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Loretteville.1971 à/to 1973 incl.Sainte-Agathe-des-Monts 1953 à/to 1973 incl.Bedford.1965 à/to 1973 incl.St-Félicien.1973 St-Jean.1972 et/and 1973 Sherrington.1971 et/and 1973 Jonquière.1965 à;to 1968 incl.1970 à/to 1973 incl.Outremont.1965,1967.1969.1970, 1972, 1973 Granby.1966 à/to 1973 incl.Quyon.1965 à/to 1967 incl.1973 Hull.1966 a/to 1973 incl.Verdun.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1968, 1972, 1973 Malartic.1965 à/to 1967 incl.1972, 1973 Lachute.1965.1971 à/to 1973 incl.St-Francois.1971 et/and 1973 Granby.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Greenfield Park.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1968 incl 1972, 1973 Montreal.1966.1972, 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 8607 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed GERARD GUAY AUTO ELECTRIQUE INC.30150 J.T.GUIMOND & FILS INC____ 83443 HARCO INDUSTRIES LIMITED 89110 HARMONIE DE WATERLOO INC 83824 ANTOINE HARRISON INC 84552 JOE HART LIMITED 89485 HOWARD HEAFEY LTD 30750 HELLENIC HOUSING CO.LTD 87032 HERCULES FLOORING INC 90488 HERITAGE HOMES LTD.88923 G.HILLEBRAND INC.90645 HOCHELAGA MORTGAGE INC.83961 HOPETOWN SPORTS CLUB INC.87977 HOPITAL ARCHAMBAULT (1964) INC.84556 HOTEL LE MONTAGNAIS INC.85819 HOTEL LOBBY DIRECTORY INC 83872 HOTEL MOTEL SHERBROOKE INC.86809 HOTEL REDO SENNETERRE INC.89597 HOTEL RICHELIEU (ST-FELICIEN) LTEE 90801 HOTEL-PLAGE CHATEAUGUAY INC.85683 HOW AC INC 83874 LES HUITAINES DE GAIETE INC.91719 LIN HURON INC 87574 PHILIPPE H U RTE AU INC.86659 IDEAL REFRIGERATION & AIR CONDITIONING INC 91798 Québec.Montreal.Montreal.Waterloo Matane.Pointe-Claire.Maniwaki.Montreal.Montreal Pointe-Claire.St.Eustache.Montreal.Hopetown.Verdun.ScheServille .Sherbrooke.Sherbrooke .Senneterre.St-Félicien.Châteauguay Montreal.Roberval.Montreal .Montréal.1954 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1967.1969, 1970, 1972.1973 1965, 1968, 1971, 1973 1965 à/to 1973 incl.1965, 1967 à/to 1973 incl.1955 à/to 1973 incl.1966, 1968 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966 ct/and 1973 1966, 1970 à/to 1973 1965 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1968 incl., 1971 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1966.1969.1973 1970 à/to 1973 incl.1966, 1968 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966, 1968, 1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl. 8608 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 197A, Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LES IMMEUBLES COTE INC.87663 LES IMMEUBLES DROUIN LTEE.91799 LES IMMEUBLES DUMAS LTEE.91610 LES IMMEUBLES DES GOUVERNEURS LTEE.89813 LES IMMEUBLES J.B.INC.84139 LES IMMEUBLES MONACO INC.82260 LES IMMEUBLES PORTOF1NO INC.91239 LES IMMEUBLES QUEMONT INC.88194 IMPRIM-ART INC.87653 IMPRIMERIE DU NORD LTEE 211806 LES INDUSTRIES ARUNDEL INC.90941 LES INDUSTRIES H.L.R.LTEE.92561 LES INDUSTRIES ROBILLARD LTEE.83662 LES INDUSTRIES DE ST-ANDRE LTEE.85351 L'INSTITUT POUR L'EDUCATION DES CHAUFFEURS INC.91614 INSTITUT PASQUIER INC.82012 INSTITUT DE REHABILITATION RICHELIEU POUR LES ENFANTS HANDICAPES, INC.90572 INTERLACHEN DEVELOPMENT CORPORATION (MONTREAL) LTD.87985 Rivière-du-Loup.Amos.St-Félicien.Québec.Jonquière.Montréal.Montréal.Montréal.Lasalle.Dolbeau.Arundel.Sillery.St-Michel.St-André.Montréal.Montréal.Hull.1966 à/to 1973 incl.1966 et/and 1973 1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965, 1972, 1973 1968 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1968, 1972, 1973 1966 à/to 1973 incl.1932 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1965, 1966, 1973 1965 à/to 1973 incl.1966, 1970 à/to 1973 inc 1.1967, 1971.1973 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.INTERNATIONAL PROCEDURES LTD.88649 LES INVESTISSEMENTS C ET C LTEE.86310 Montreal.Montréal.INVESTISSEMENTS R.B.LTEE.90151 INVESTISSEMENT TOTEM INC.92202 ITALARTIGIAN CORPORATION .90810 L.JAM INC.84568 St-Antoine-des-Laurentides St-Eustache Montreal.Plessisville.1966 à/to 1973 incl.1973 1969 à/to 1973 incl.1972 et/and 1973 1969 à/to 1973 incl.1965 et/and 1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8609 Nom de la compagnie Adresse Rapports non produits Name ojthe company Address Returns not filed JARDIN BELVEDERE INC.Sherbrooke.1965 à/to 1970 incl.1973 82092 JARDINS METROPOLITAIN LTEE.Montréal.1966 à/to 1973 incl.91070 JARDINS ST-TROPEZ INC.Montreal.1965 à/to 1973 incl.85548 JEANNOTTE CONSTRUCTION LTEE.Chomedey.1966.1971 à/to 1973 incl.87039 JEAN-PIERRE COIFFURE INC.Montréal.1972 et/and 1973 83025 JEUNE CHAMBRE DU DISTRICT DE VAUDREUIL.Dorion.1966 à/to 1973 incl.90494 JEUNE CHAMBRE DES ESCOUMAINS INC.Escoumains .1965 à/to 1968 incl, 1973 85919 LA JEUNE CHAMBRE DE SAINTE-ROSE.Ste-Rose.1965 à/to 1973 incl.85661 JEUNE CHAMBRE VAL-D'OR INC.Val-d'Or.1973 83667 JOBIN LTEE.Boucherville.1966 à/to 1970 incl., 1973 89373 VALMONT JOBIN LIMITEE.Charlesbourg .1966, 1968.1969, 1971 82342 à/to 1973 incl.TONY JOLIN 4 ASSOCIES (1966) INC.Laval.1970 à/to 1973 incl.93079 JOLY BUNGALOW LTEE .Laval.1966 à/to 1973 incl.88654 JUBINVILLE ET TRUDEAU INC.Ste-Thérèse.1966 à/to 1973 incl.87042 K 4 K LIMITED.Montreal.1972 et/and 1973 87129 K.4 L.INVESTMENTS LTD.Montreal.1966 à/to 1973 incl.92100 K.L.MFG.LTD.Montreal.1967 à/to 1973 incl.89493 KATZ DEVELOPMENT CORP.Montréal.1973 88656 KEBEC-COLA INC.Magog.1965, 1972, 1973 85471 KEITH HOLDING CORP.Montreal.1966 à/to 1973 incl.91354 KEN-ALL HOLDINGS LTD.Montreal.1966 à/to 1973 incl.92204 KINETIC INTERNATIONAL CORP.Montreal.1972 et/and 1973 93169 KINGSBORO COURIERS (QUEBEC) LTD.Montreal.1972 et/and 1973 92569 KINTOL ASSOCIATES INC.Montreal.1968, 1969, 1972, 1973 89495 KIRKLAND EQUIPMENT LTD.Beaconsfield.1968.1970 à/to 1973 incl.91072 S610 Ql'F.liEC OFFICIAL GAZETTE, Nowtmber in.iu: ;.V\u201el.106, .V.,.Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed L.4 W.INVESTMENTS INC.90576 LA REGENCE SALES AGENCY LTD.91114 THE LA TUoUE SHIRT COMPANY LIMITED 86189 LABELLE ENTERPRISES INC.91947 LABONTE, LALONDE.INC____ 213976 LES LABORATOIRES HALIN LIMITEE 87874 LACHENAIE PROJECTS CORP.86184 LACHINE RACING CANOE CLUB INC.86317 CLEMENT LACOURSIERE CONSTRUCTION LTEE 85472 LAITERIE DU TEMIS LTEE.82438 LAKESHORE MEDICAL ARTS BUILDING INC.93172 LEONARD LALONDE INC.89US LAMONTAGNE ET BARIL BRULEURS A L'HUILE INC.231905 BERNARD LANOIX (1965) LIMITEE 86575 ROLLAND LAROCHE 4 ASS.INC.S5473 LATOUR 4 HODGE INC.89710 LAURENTIAN VENEER AND PLYWOOD LTD.91620 LAURENTIDE DRIVING CLUB 91407 LAURENTIDE KARTWAY CO.LTD.91809 LAURENTIDE VACATION HOMES INC 89711 LAVAGE D'AUTO GAGNON INC 90029 Montreal.Montreal.Montreal.Laval.Montreal.Donnacona.Montreal.Lachine.Berthierville-.Cabano .Pointe-Claire Montréal.Thetford Mines Berthierville Montréal.Montreal.St-Jérôme.Terrebonne.Montreal.Montreal.Montréal.LAVAL CONCRETE FLOORS INC.Montreal 87452 LAVAL DEVELOPMENT INC.Montrcal LAVAL DEVELOPMENT LIMITED.Montreal LAVE-AUTO C1IAMPLAIN LTEE.St-Jean 86576 1966.1968 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1965.1967, 1968, 1973 1973 1954 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965, 1968 à/to 1973 incl.1965 à/to 1970 incl.1972 et/and 1973 1965 et/and 1973 1965.1967.1973 1967.1969 à/to 1973 incl.1966à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1966, 1969, 1970.1972, 1973 1965 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966, 1968, 1972, 1973 1966 à/to 1973 incl.1972, 1973 1968.1972, 1973 1966 à/to 1969 inch, 1971 à/to 1973 incl.1972, 1973 1973 1972.1973 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1971.106' année.n° 1,6 8611 Nom de la compagnie Name of the company ROGER LE BEL INC.84581 LE VALOIS CONSTRUCTION CO.INC.92898 PERRY LEE WHOLESALE FLORISTS INC.86483 LEFEBVRE ET ASSOCIES INC.83674 DONAT LEGER INC.92210 LEIMIL HOLDINGS CORP.84308 LEKTRONIC SALES LTD.87571 MAURICE LEMIEUX LTEE.86578 LEONARD ENTERPRISES INC.83470 LEO'S BOYS SPORTS ASSOCIATION INC.82350 GERARD LEPAGE & FILS INC.91249 LERAN COPPER MINING COMPANY LIMITED (NO PERSONAL LIABILITY) 43340 LIBRAIRIE PLAZA INC.91251 LA LIGUE CIVIQUE DES CITOYENS DE VILLE ILE- PERROT 88540 LA LIGUE DE HOCKEY INTERMEDIAIRE DE SOREL INCORPOREE 37897 LIGUE DES PROPRIETAIRES DE LA PAROISSE DE ST- LEONARD-DE-PORT-MAURICE 29164 LIGUE DES PROPRIETAIRES DU QUEBEC.85553 LINTON LUNCHEONETTE LTD.87737 LISTA INC.92211 LLOYD PRINTING LTD.87738 LES LOCATIONS ROCHELEAU LIMITEE.89383 LOGO INC.89833 LES LOISIRS DE BAIE ST-PAUL INC.22996 LOISIRS DE BLUE SEA INC.87739 Blue Sea.1966 à/to 1973 incl.Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Ste-Thérèse.1965.1966.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Jacques-Cartier.1965 à/to 1973 incl.L'Annonciation.1966 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1968 à/to 1973 incl.Rivière-du-Loup.1971 et/and 1973 Cowansville.1965, 1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1964 à/to 1968 incl., 1970 à/to 1973 incl.Ste-Anne-des-Monts.1966 à/to 1973 incl.Québec.1958 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1966 à/to 1971 incl., 1973 Ile-Perrot.1973 Sorel.1957 à/to 1973 incl.St-Léonard-de-Port- 1955 à/to 1973 incl.Maurice Salaberry-de-Valleyfield.1965, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Beloeil.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montréal.1970, 1973 Cap-de-la-Madeleine.1970,1971,1972,1973 Baie-St-Paul.1967 à/to 1973 incl. 8612 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LES LOISIRS DE ST-FERDINAND.84411 LOISIRS ST-GAETAN INC.82016 LOISIRS DE ST-LIGUORI.85944 LES LOISIRS ST-LUCIEN.84156 LES LOISIRS SAINT-MATHIEU (CO.LAPRAIRIE) INC.83147 LES LOISIRS ST-THEODORE DE CHERTSEY INC.84410 LES LOISIRS DE TCHITAGAMA INC.90579 LOISIRS TOURISTIQUES DE ST-THEODORE-DE-CHERTSEY INC.84157 LOULICA INC.86194 LUCERNE DEVELOPMENTS LTD.93298 O.LUSSIER & FILS INC.85554 LYNN ENTERPRISES LIMITED.83678 M.D.J.ANIMAL FOOD PROVISIONERS LTD.87456 M.K.CONTRACTORS LTD.86197 M & M SUPER MARKET INC.84585 M & P MARINE LEASING INC.88949 J.MACDONALD & ASSOCIATES INC.88543 MACETHEL CORP.93366 MACHINEX EQUIPMENT LTD.91957 MAÇONNERIE MODERNE INC.86826 LA MAÇONNERIE SALABERRY INC.90034 LES MAGASINS YOLANDE LIMITEE.24373 MAGI AUTOMOBILES LTEE.88126 MAGI-KLEAN MAINTENANCE INC.87135 LA MAISON MAURICE INCORPOREE.85362 Bernierville.1965.1967.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.St-Liguori.1966.1967, 1972 et/and 1973 St-Jean.1965 à/to 1973 incl.St-Mathieu.1965 à/to 1973 incl.St-Thédore-de-Chertsey.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Notre-Dame-du-Rosaire.1966, 1970, 1973 St-Théodore-de-Chertsey 1965, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1967 incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1970, 1972, 1973 Montréal.1965.1967.1969 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1965 à/to 1967 incl.1971 à/to 1973 incl.Terrebonne.1966, 1972, 1973 Montreal.1965 et/and 1973 Montreal.1965 à/to 1967 incl.1973 Lachine.1966 à/to 1973 incl.Mount-Royal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Joseph.1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1969, 1971 à/to 1973 incl.Salaberry-de-Valleyfield GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974.106' année, n\" 16 8613 Adresse Rapports non produits Addreu Return) not filed Montréal.1972.1973 Montréal.1955 à/to 1973 incl.Grand'Mère.1962, 1966 à/to 1973 incl.Cowansville.1966 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.Granby.1964 à/to 1973 incl.Ville St-Pierre.1969 à/to 1973 incl.Jonquière.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Léonard.1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Ville St-Laurent.1954 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965.1967.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1967.1971 à/to 1973 incl.Longueuil.1973 Sherbrooke.1965 à/to 1973 incl.Québec .1967, 1970 à/to 1973 incl.Cop-de-la-Madeleine.1971 à/to 1973 incl.Québec.1955 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1967 incl.1969.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1969 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles.1965 à/to 1967 incl.1970 à/to 1973 incl.Nom de la compagnie Same of the company MAISON PIERRE LE MOYNE SIEUR D'IBERVILLE INC.87252 LA MAISONNETTE INC.32517 LES MAJORETTES DE GRAND'MERE INC.66453 LES MAJORETTES OPTIMISTES DE COWANSVILLE INC.86491 MAJORETTES STE-JEANNE D'ARC DE GRANBY INC.74178 LES MAJORETTES DE VILLE ST-PIERRE INC.82819 MARCEL MALTAIS MEUBLES LTEE.90276 MANOIR INVESTMENTS LTD.91363 ROGER MAN8EAU LTEE.90028 MANSIONS TOURIST HOTEL INC.86581 MANUFACTURERS WHOLESALE HOUSE INC.29245 MARCHE LP.INC.86582 MARCHE PIERRE LTEE.86492 MARDA INC.86201 MARINA VILLE MARIE INC.89128 MARJEAN INC.84961 MARQUETERIE RICH-WOOD INC.82104 MARTIN MANUFACTURING CO.LTD.83684 MARVEL GRANITE INC.33714 LE MAS DES OLIVIERS INC.87458 MASAD INC.87062 MASSON MANSIONS LTD.83326 MASTER ELECTRICAL REPAIRS INC.86494 JEAN-PAUL MATTEAU LIMITEE.85936 s614 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1971.Vol.106.No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed l.r.Mcdonald & fils (quebeq ltee.92109 McGARR MARINE LTD.85213 MEDICAL-DENTAL CREDIT BUREAU OF NORTH AMERICA INC.87255 L.MERCIER & FILS INC.90039 METAL PROCESSING CO.LTD.27031 METRO HANDBAGS COMPANY 83162 METRO MORTGAGE CO.LTD.83797 MICO MINING & DEVELOPMENT CORPORATION (NO PERSONAL LIABILITY) 33493 MICRON CORPORATION.88464 MILGORN INVESTMENT CORP.85940 MIMICO INVESTMENT CORP.82281 MINES DE ST-URBAIN LTEE (LIBRE DE RESPONSABILITE PERSON N ELLE> 85371 LES MIROIRS ST-ANTOINE INC.82355 MISS QUEBEC RACING TEAM INC.88952 MISSISQUOI DEVELOPMENTS INC.89133 MOBER AVIATION INC.89136 MODERN THERMO-CRETE INC.36897 MONA FARMS INC.82139 MONDAIRE INC.88465 Montréal.Longueuil.Montreal.St-Roch-Ouest Verdun.Montreal.Montreal.Montreal.Anjou.Montreal.Montreal.Montréal.St-Antoine-des-Laurentides Beloeil.St-Lanrent.Drummondville .Montreal.Montreal.Montréal.MONKLAND TOWERS INC.Hampstead.MONSIEUR ELEGANT INC.Saint-Jérôme.843213TREAL CABLE SYSTEMS INC.Montreal MONTREAL CHINESE DEVELOPMENT INC.Montreal all 27 MONTREAL EXCAVATION INC.Montre.1 1966 à/to 1973 incl.1965.1969.1973 1966 à;to 1973 incl.1973 1953 à/to 1973 incl.1973 1965 à/to 1967 incl.1969 à/to 1973 incl.1956 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1967.1968,1973 1971 à/to 1973 incl.1968 à/to 1973 incl.1967, 1970, 1973 1957 à/to 1973 incl.1965.1972, 1973 1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1966, 1967, 1973 1965 à/to 1973 incl.1966 et/and 1967.1969 à/to 1973 incl.1965, 1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, le novembre MA, 106' année, n° 16 8615 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed MONTREAL REINFORCING STEEL CORPORATION .86837 MOTEL LA VALLIERE, INC.88924 MOTEL QUEBEC INN INC.92113 MOULIN VAL-ST-GILLES LTEE 82020 THE MOUNTAIN LAKES ASSOCIATION 87519 MULTICOM INC.86039 NAGA INC.90964 NATIONAL RENOVATERS LTD.85725 NEO-TECH-ART INC.NETTOYEURS L.M.LTEE 83175 NETTOYEUR PLACE VICTORIA INC.92115 NETTOYEURS WRIGHTVILLE INC.87140 NEW ERA HOME APPLIANCES (QUEBEC) LTD.91974 NEW SERVICE RESTAURANT LTD.85761 NEW SYSTEM LUNCH LTD.85563 NEWCO INC.86500 NEWPORT ENTERPRISES LTD.86834 NICK TRANSPORT LTEE.89278 C.V.F.NIELSEN INC.88008 NOIK ABELSKY LTD.84875 NORDICO INC.109150 E.NORMAND INC.90590 JACQUES NORMAND EQUIPEMENT LTEE.88009 NORMAND MINES LTD.(NO PERSONAL LIABILITY).86840 Montreal.St-Félicien.L'Ancienne-Lorette.Aylmer.Rawdon.Montréal.Duvernay.Chomedey.Montreal.Jonquière.Montréal.Hull.Montreal.Montreal.Montreal.Chomedey.Montreal.Sherbrooke.Montreal.Montreal.Sainte-Adole.Ste-Foy.St«-Foy.Noranda.1966 à/to 1973 incl.1973 1966, 1973 1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1973 1965, 1966, 1967, 1969 à/to 1971 incl.1973 1966 à/to 1973 incl.1967.1969 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1971, 1973 1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1967 incl.1972 et/and 1973 1965, 1967.1968.1970 à/to 1973 incl.1965, 1972, 1973 1965.1966, 1973 1966 à/to 1973 incl.1966 et/and 1973 1965 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1966 et/and 1973 1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl. 8616 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1974, Vol.106, No.Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed NORTH END BUILDING CORPORATION.85227 NORTHLAND ENTERPRISES LTD.92485 LE NOUVEL EGREGORE.90966 NOUVELLE LAMPE (QUEBEC) INC.88550 NUWAY FLOOR COVERING LTD.84974 O.E.M.ENTERPRISES INC.90967 OAK-MOUNT LIMITED.83178 O'CONNOR ENTERPRISES LTD.86504 L'OEUVRE DES LOISIRS DE ST-FIRMIN DE BAIE STE- CATHERINE INC.84328 L'OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE LAURIER STATION (L'O.T.J.DE LAURIER STATION) 46870 L/OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX (O.T.J.) DE MARIA.NORMAN OLSON ASSOCIATES LIMITED.85945 J.E.O'NEIL ELECTRIC INC.84976 ORDRE DE SAINT-GENEST.235859 ORFAC INC.82504 ORIS INC.87585 ORLY DIAMONDS LTD.91099 R.OUELLETTE AUTOMOBILE INC.83692 OXFORD WOOLLENS & WORSTEDS LTD.86239 OZAK CORPORATION.90287 P.A.SUPERMARKET CO.LTD.84978 P J'S INC.90845 PALMA RESTAURANT INC.84607 PARADISE RESTAURANT LTD.92335 Montréal-Nord.1965, 1966.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to ly73 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Montreal.1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Dorval.1972 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1971 à/to 1973 incl.Baie Ste-Catherine.1965 à/to 1967 incl.1973 Laurier-Station.1961 à/to 1965 incl., 1967 à/to 1969 incl., et/and 1972 Maria.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Campbell's Bay.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1959 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1965, 1967 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965.1971 à/to 1973 incl.Hampstead.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1966, 1972 à/to 1973 incl.Montreal.i966 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.St-Lambert.1966 à/to 1969 incl 1971 à/to 1973 incl'. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1974.100' année.»° 40 8617 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed LE PARC DE L'EST INC.85730 PARC SEIGNEURIE SOULANGES INC.89146 PARCO CLEANING SERVICES LTD.84421 PARK PLAZA INC.85230 PARMIL LTEE 89511 LES PASTOUREAUX DE CHAMBORD INC.91819 PATSILK INVESTMENT CLUB INC 90596 PEERLESS ENTERPRISES INC.88552 LES PEINTRES RICHELIEU INC.86999 P.A.PELLETIER LTEE 87589 PELLETIER.RIOUX INC.108227 PELUSO 4 FILS CONSTRUCTION INC.93381 ROBERT PEPIN INC.84748 PEPINIERE FLORALIES LTEE 84982 PERIBONKA MINING COMPANY LTD.(NO PERSONAL LIABILITY) 88141 PERMAMOUNT INC.93382 PETER LAND CORPORATION.89148 PETERCO DEVELOPMENT INC.85839 LES PETITS CIREURS INC.91379 LES PETROLES BRASSARD LTEE 105778 J.N.PHILIPPE JOYAL LTEE.25317 LES PHOTOGRAPHES ELLEFSEN LTEE.90051 GILBERT PICHETTE LTEE.87262 PICTURE WORLD ENCYCLOPEDIA LTD.33797 PIETRO 4 DOMINIQUE IMPORTING LTD.91823 Magog Coteau-du-Lar.Longueuil.Montreal St-Jean.Chambord.Montreal.Montreal.Montréal.Rivière-Malloie St-Pascal.Angliers.St-Georges .Fabreville.Jonquière.Montreal.Montreal .Montreal.Montreal .Roberval.Sorel.Chicoutimi.Villeneuve.Montreal .Montreal .1969 à/to 1973 incl.1967.1973 1965 à/to 1969 incl., 1971 à/to 1973 incl.1971, 1973 1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1973 1967.1969 à/to 1971.1973 1970 à/to 1973 incl.1966 à/to 1969 incl.1971 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1972.1973 1965 à/to 1967, 1972, 1973 1965.1970 à/to 1973 incl- 1967 à/to 1969.1971 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1952 à/to 1973 incl.1967, 1972,1973 1973 1966 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl. so 18 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November IS, 197A, Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company PINE HILL SAND AND GRAVEL INC.88692 PISCICULTURE DE LA RIVIERE DE L'OUEST INC.85387 LES PISTES D'AUTOS MINIATURES DE TROIS-RIVIERES INC.84613 PIZZA GASTONE LTD.93096 PLACE CHOMEDEY INC.82111 LES PLACEMENTS ANJOU INC.89284 PLACEMENTS C.V.INC.92224 LES PLACEMENTS COURVILLE LTEE.88555 LES PLACEMENTS DUSATRIN INC.234028 LES PLACEMENTS ECLAIR LTEE.86694 PLACEMENTS FORTUNA INC.88250 LES PLACEMENTS FUTURA INC.91105 LES PLACEMENTS G.L.S.LTEE.88684 PLACEMENTS GEMINI LTEE.88016 LES PLACEMENTS LE FORT INC.84984 LES PLACEMENTS LTMCO INC.83907 PLACEMENTS LOUIS ET PAUL LTEE.83493 LES PLACEMENTS M.D.R.INC.88558 LES PLACEMENTS MANITOU INC.93099 LES PLACEMENTS MARCEL DESOURDY INC.88251 LES PLACEMENTS MUTUELS SELECTION INC.89285 LES PLACEMENTS MYRTIL LIMITEE.85391 LES PLACEMENTS DU NORD DE L'OUTAOUAIS LTEE.91381 LES PLACEMENTS PATENAUDE LTEE.84623 LES PLACEMENTS RENAUD INCORPOREE.92120 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Laval-des-Rapides.1968 à/to 1973 incl.Lorraine.1965 à/to 1973 incl.Trois-Rivières-Ouest.1965.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1969 à/to 1973 incl.Chomedey.1973 Montréal.1973 Laval.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966.1972,1973 Montréal.1967,1969 à/to 1973 incl.Montréal.1973 Anjou.1973.Montréal.1966.1968 à/to 1973 incl.Pointe-aux-Trembles____ 1966.1968, 1970 à/to 1973 incl.St-Eustache.1966, 1969, 1971,1973 Montréal.1970,1971,1973 Québec.1965.1967,1973 St-Michel.1965 à/to 1973 incl.St-Brunc-de-Montarville 1966 à/to 1973 incl.Laval.1973 Laflèche.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1965, 1967, 1971 à/to 1973 incl.Hu\".1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Montréal.1965,1967,1968,1970 à/to 1973 incl.Montréal.i966 j;t0 1973 inc] GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 8619 Nom de la compagnie .Yame of the company LES PLACEMENTS ROLAND DESOURDY INC.88252 LES PLACEMENTS SIMCO INC.91993 PLACITRE INC.82115 E.G.PLANTE GARAGE INC.PLAYWRIGHTS WORKSHOP (MONTREAL) INC.91107 PNEUS JARRY INC.88018 POINTE-CLAIRE AUTO CLINIC INC.93385 POLLACK INSURANCE AGENCY INC.91382 PORT ROYAL PAVING INC.84987 PREMIUM PROMOTIONS INC.90295 PRIMA BRAND INC.83911 PRIME REALTY' CORP.88019 PRO ENTERPRISES INC.92343 PRODUCTIONS DE TELEVISION ITALIENNE MONTREAL INC.88144 LES PRODUITS SANITAIRES ROMA INC.84338 PROGRESSIVE DESIGN INC.84988 PROMENADE FLEURY INC.91829 PROMOFINA INC.89430 PROVINCIAL ELECTRIC CO.LTD.88336 PUBLICA INC.92123 PUBLICATIONS PERICLES INC.90516 QUEBEC ASSOCIATION OF INDEPENDENTS SCHOOLS.83346 QUEBEC DUNE BUGGY SALES INC.113267 QUEBEC GRAPHICS ARTS EQUIPMENT LTD.83706 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Laflèche.1970 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1970 à/to 1973 incl.Charlesbourg.1973 Leinoyne.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Ville St-Michel.1969, 1970, 1972,1973 Pointe-Claire.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 et/and 1966, 1968 à/to 1973 incl.Laval.1969,1970,1972,1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1968, 1971, 1973 Les Saules.1966.1968.1972,1973 Montreal.1965.1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.St-Laurent.1971, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Aima.1966 à/to 1969 incl., 1972 et/and 1973 Montréal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Montreal.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1971 à/to 1973 incl. 8620 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Addreee Rapports non produits Returns not filed QUEBEC INVESTMENT AND ADMINISTRATION CORP.88257 QUEBEC TEA LTD.83195 QUEEN FASTENER CORP.92001 R.& L.MAÇONNERIE LTEE.89061 RAGEOT LTEE.91384 RANCH ALGONQUIN INC.82440 RAPHAEL INTERNATIONAL INC.83939 RAVENCO INC.86250 RAYMOR CORPORATION.84339 READERS LEAGUE INTERNATIONAL LTD.92004 RECOUVREMENTS SPECIALISES INC.88694 REGIONAL PROPAN GAS LIMITED.24865 RELIABLE PUBLIC RELATIONS & ACCEPTANCE SERVICES LTD.90201 LES RENARDS CLUB DE HOCKEY IBERVILLE INC.76643 RESTAURANT BOUL.DE MAISONNEUVE INC.120537 RESTAURANT CROISSANT INC.92412 RESTAURANT LE BARILLET PUB INC.87270 RESTAURANT LE TISON LIMITEE.82372 RESTAURANT PLACE ROYALE INC.85578 RESTAURANT VIMONT INC.84637 REVELATION COSMETICS INC.91116 RICHARDSON INC.89526 RICHMAKE PRINTING & LABEL CO.LTD.91660 PAUL RIVARD IMMEUBLES LTEE.88698 RIVERSIDE INDUSTRIAL PARK LTD.88148 Montreal.1972.1973 Montreal.1972, 1973 Montreal.1966.1967 et/and 1973 Boucherville.1969 à/to 1973 incl.La Providence.1966, 1967.1969, 1970, 1972, 1973 Pincourt.1965.1967 à/tol969incl.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1973 Montreal.1965 à/to 1971 incl.et/and 1973 Outremont.1965, 1972.1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1966.1967, 1971 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1952 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Iberville.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1971 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1973 St-Raymond.1967 à/to 1969 incl., 1972, 1973 Sorel.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.Vimont.1965 à/to 1967 incl., 1969, 1972, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Sherbrooke.1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1970 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1971, 100' année.n° 16 8621 Nom de la compagnie yVame of the company Adresse Address Rapporta non produits Returns not filed RIVIERA LAVAL INC.87074 ROCHEFORT CONSTRUCTION INC.88481 Laval.ROGER DE PARIS COIFFURE INC.82299 ROGER VENTILATION INC.88875 ROMER (CANADA) INC.85962 ROSS DRAPERIES INC.88341 ROTED INC.87769 PAUL HENRI ROTH INC.92351 G.L.ROULEAU INC.88699 J.R.ROUTLIFFE ENTERPRISES LTD.85485 S.D.INDUSTRIES AGENCY LTD.87272 ST-DENIS PLASTERING INC.87077 STE-FOY TRACTO-MECANIC INC.88483 L.ST-GERMAIN FRERES, LTEE .88701 ST-HILAIRE AUTO INC.88980 ST.JOHNS METAL STAMPING INC.84642 STE-JUUE TRANSPORT INC.92U9S ST-MAURICE SCRAP METALS INC.93106 SAGIO ENTERPRISES LIMITED.82301 SALAISON DOMAINE INC.91736 SALEMARK ASSOCIATES LTD.88342 SALLE DE QUILLES LEBRUN INC.83921 SALON DE CROQUET QUEBEC INC.66200 SALON ESPERANTO LTEE 91391 SALON MAXIME ET ANDRE INC.92503 Salaberry-de-Valleyfield Mont-Royal.St-Jean.Montreal.Montreal.Rosemère.L'Ancienne-Lorette.Montréal.Fort-Coulonge.Montreal.Montreal.Ste-Foy.Sorel.St-Hilaire.St-Jean.Varennes.Trois-Rivières.Montreal.Montreal.Montreal.Montréal., Québec.St-Hubert.Montréal.1966 à/to 1973 incl.1967.1969 à/to 1973 incl.1967.1969 à/to 1973 incl.1973 .1970,1971,1973 1966, 1970, 1973 1966 et/and 1967, 1969 à/to 1973 incl.1966.1967, 1969 à/to 1973 incl.1966, 1971.1973 1965 à/to 1973 incl.1969 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1973 1966.1969, 1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1967, 1972, 1973 1973 1965 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1971 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1962 à/to 1973 incl.1966, 1970 à/to 1973 incl.1973 8622 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971,, Vol.106, No.16 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed SALON VARIETE INC.83714 THE SANDBORN FOUNDATION 89306 SANTOS INVESTMENT CORP.85753 SARAGUAY MANAGEMENT INC.88704 SAVRIN INC.86862 JOSEPH SCALIA CONSTRUCTION LTEE.83030 SCENE PUBLICATIONS LIMITED.92355 SCIENTIFIC PUBLIC RELATIONS LTD.84858 SECRETARIAT MEDICAL DOSTALER INC.83921 SELECT-O-SONORE INCORPOREE.90990 ROGER SENECAL INC.91738 SEPT-ILES TAXIS INC.83356 SERVI TRONIC INC.89161 SERVICE D'AIDE AUX PRISONNIERS DE SHERBROOKE INC.82375 SERVICE D'AUTOS ET PNEUS CAP-DE-LA-MADELEINE INC.93409 SERVICE COMMERCIAL D'ORDINATEUR INC.89212 SERVICE DE CONSULTATION EXCELSIOR LTEE 83517 SERVICE D'EXPEDITION TRANS-QUEBEC INC 92504 LE SERVICE DU VESTIAIRE (ST-JEROME) INC.92130 Québec.Montreal.Montreal.Montreal.Ste-Rose.Montréal.Montreal.Montreal.Montreal.Québec.Montréal.Sept-Iles.Ste-Agathe-des-Monts.Sherbrooke.1965, 1966, 1968 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965, 1966.1968, 1970 à/to 1973 incl.1967,1969 à/to 1971 incl., 1973 .1970 à/to 1973 incl.1973 .1966 à/to 1973 incl.1965.1970 à/to 1973 incl.1965, 1967, 1968, 1973 .1971 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965, 1973 .1968 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.Cap-de-lo-Madeleine.SIMARD AMIN INC.90611 TELESPHORE SIMARD INC.91287 SIMON RIVER DEVELOPMENT INC 85848 SIROCO INVESTMENT CORP.86063 ' ' SKI-DOO RAMA INC.83033 Montréal.Montréal.Pointe-Claire.St-Jérôme.Montréal.L'Ancienne-Lorette.Montreal.Montreal.1969 à/to 1973 incl.1973 1965 à/to 1968 incl.1971 à/to 1973 incl.1970 à/to 1973 incl.1973 1968 à/to 1973 incl.1967 à/to 1973 incl.1966 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.1965 à/to 1973 incl.Longueuil. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 197Â, 106' année, n° 16 8623 Nom de la compagnie Name of the company SMITH LITHOGRAPHING AND ART INC.93413 SNOWDON DEVELOPMENT CORPORATION.88154 SNOWDON RESIDENTS' ASSOCIATION.87907 LA SOCIETE COMMERCIALE DUBOTVIER INC.83521 SOCIETE DE CREDIT POPULAIRE INC.83214 SOCIETE DE GESTION DES BOIS-FRANCS INC.91473 SOCIETE DE GESTION GILLES PARANT.LTEE.93415 SOCIETE IMMOBILIERE DU ST-LAURENT INC.88156 SOCIETE D'OUTILLAGE M.R.LTEE.86596 LA SOCIETE DE LA PLACE ROYALE DE QUEBEC.83719 LA SOCIETE DE PLACEMENT ET D'INVESTISSEMENT KYRIEL INC.91289 LA SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE D'ARVIDA.24837 SOCIETE DES SPECIALISTES EN FOURRURE DU QUEBEC INC.91394 SOCIETE SPORTIVE SAINT-LOUIS INCORPOREE.43919 SOCIETE DE VILLEGIATURE DE ST-UBALD INC.86346 LA SOCIETE ZOOLOGIQUE DE LTLE-AUX-COUDRES.91671 SOCOMONT INC.87780 SOLVER INC.90661 SOREL FUMIGATION LIMITEE.33206 SOUTH AMERICAN PROMOTIONS INC.87783 SPEAR CORPORATION LTD.89541 SPENSIERI & DI BIASE CONSTRUCTION INC.84322 STANLEY CASTLE BUILDING LTD.92024 STATIONNEMENT RAPIDE LTEE.85253 Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Dollard-des-Ormeaux.1967 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Québec.1973 Montréal.1969 à/to 1973 incl.Victoriaville.1966, 1968 à/to 1973 incl.Ste-Thérèse.1972 et/and 1973 Sept-Iles.1971 à/to 1973 incl.St-Laurent.1972 et/and 1973 Québec.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1969 à/to 1973 incl.Arvida.1952 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967,1972, 1973 St-Jean-de-la-Lande.1958,1960,1963.1972 St-Ubald.1967, 1969 à/to 1973 incl.St-Louis-de-lTle-aux- 1966 à/to 1973 incl.Coud res.St-Léonard.1968, 1970 à/to 1973 incl.Lauzon.1966 à/to 1973 incl.Sorel.1956 à/to 1973 incl.Montréal.1967.1968, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968,1969,1973 Montreal.1965, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl. 8624 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Nom de la compagnie Name of the company LEON STEINBERGER SCHOOL BUS SERVICE INC.88261 H.STEINBERG'S KOSHER MEAT MARKET CO.32578 STUDIO FIGURAMA INC.85940 STYLE-TREND FASHIONS LTD.84213 LA SUISSE DE L'ESTEREL LTEE.82309 SUMIK GENERAL MANAGEMENT, INC.138429 SUPER MARCHE FILIAULT LTEE.83037 SUPERIOR PLASTERING LTD.92365 SUPERIOR POOLS (QUEBEC) LTD.85419 LES SURPLUS ECONOMIQUES INC.85008 SYNDEX INC.90615 TABAGIE RACINE INC.90874 JOSEPH TABAH ET FILS LTEE.83038 Y VON TANGUAY LTEE.82575 TECABON LIMITEE.90014 TECHNILOK INC.90524 TECHNIQUES D'ORGANISATION ET DE RENDEMENT LTEE 89889 TELCO ADMINISTRATION INCORPORATED.82577 TELE-CABLE REGIONAL INC.86599 TELIS CO.LTD.89543 TELSTAR PRODUCTS LTD.83530 TENT CITY INC.88041 TERRACE STATIONERY INC.86601 .J.P.THERRIEN 1960 PARTHENA1S LTEE.56481 .THIBODEAU & LEPINE INC.909P4 .Adresse Rapports non produits Address Returns not filed Montreal.1966, 1973 Montreal.1955 à/to 1973 incl.Trois-Rivières.1965 à/to 1968 incl., 1969 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Ste-Marguerite-du-Lac- 1965, 1966, 1969 à/to Masson.1973 incl.Trois-Rivières.1972 et/and 1973 Sherbrooke.1966, 1967, 1973 Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Québec.1965 à/to 1973 incl.Québec.1966 à/to 1973 incl.Chicoutimi.1966, 1971 à/to 1973 incl.Ville d'Anjou.1973 Roberval.1965 à/to 1973 incl.St-Laurent.1969 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1967, 1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Gatineau.1966, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.St-Laurent.1965 a/to 1971 incl., 1973 Calumet.1966, 1969, 1972, 1973 Montreal.1971 à/to 1973 jnc].Montréal.1961 à/to 1973 incl.Montréal.1966 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1974, 106' année, a' 46 8625 Nom de la compagnie Xame of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed EDMARD THOMAS INC.82312 THREE-STAR CONSTRUCTION (QUEBEC) LTD.S6876 THREE STAR INVESTMENTS LTD.87286 TIBO CAR INC.87912 TIMMINS GOLD FIELD INC.83934 TODD'S HILL COUNTRY CLUB INC.86264 TORCH SKI AREA INC.83983 SERGE TRADINE INC.90867 TRANS-ILE INC.82314 LES TRANSPORTS DU GOLFE INC.88880 RENE TREMBLAY ACCESSOIRES INC.89634 TRIANGLE SERVICES INC.90999 TRIBAR ENTERPRISES INC.83936 TRIDENT IMPORT CO.LTD.91136 TRI-TECH SERVICES INC.82529 TRIUM ENTERPRISES LTD.86248 TROIS-RIVIERES AUTOS ACCESSOIRES INC.91293 LES TROIS SOURCES INC.91679 GERARD TROTTIER INC.92030 LA TROUPE MARC LESCARGOT.91002 J.R.TRUDEL LIMITEE____ 207897 TURNER HOLDINGS LTD.88263 TUYAU IDEAL INC.88359 UNITED IMPEX CORPORATION.84774 UNIVERSITY TOWERS CORPORATION.87791 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1967, 1970 à/to 1973 incl.Montreal.1968,1970 à/to 1973 incl.Pierreville.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1969, 1972, 1973 St-Gabriel-Ouest.1965 à/to 1973 incl.Sutton.1965 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Rimouski.1967,1972,1973 St-Félicien.1966 à/to 1969 incl.1973 Châteauguay.1970,1972,1973 Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1966 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1965, 1972, 1973 Trois-Rivières.1966, 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.Montréal.1966, 1967, 1972 et/and 1973 Montréal.1966 à/to 1973 incl.St-Glte.1955 à/to 1973 incl.Longueuil.1971 à/to 1973 incl.Dollard-des-Ormeaux.1968 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 8626 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1974, Vol.106, No.46 Nom de 1» compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed V.D.CONSTRUCTION INC.91402 E.VACHON LTEE .S8505 VAL DE NEIGE INC.89316 VARTAN SEFTER INC.83367 VENISE MARINE INC.92371 VERDUN CLEANERS INC.89174 VERGERS PAPINEAU INC.S9176 MARCEL VEZINA LTEE.85774 V-HANDBAG CO.INC.90079 VICTORIA COIN INC.84777 VIENNA CONSTRUCTION INC.83937 VILLA DR.LECLERC INC.84364 THE VILLAGE HEALTH STUDIO LTD.87162 VILLAGE SERVICE STATION INC.85263 VIMONT BUANDERIE AUTOMATIQUE INC.85264 VIP LEASING LIMITED 91476 VISION TEXTILES INC.1105-1539 WAKEFIELD GRIST MILL LIMITED.83231 WALLY-HAYES LTD.83370 WF.DOV INVESTMENT CORP.83732 WESTMINSTER SHOE STORE & REPAIRS INC.93125 WILSON'S FUNERAL HOME INC.WOMAN'S BUREAU.82650 HERALD WOODWARD PRESS INC.:.240537 WORLDWIDE COOPERAGE CORPORATION 83734 Montreal .1966 à/to 1973 incl.Loretteville.1966 à/to 1973 incl.Préville .1966 à/to 1970 incl., 1972.1973 Montreal.1973 Venise-en-Québec.1966.1971 à/to 1973 incl.Verdun.1973 Saint-Paul d'Abbotsford 1971 à/to 1973 incl.Montréal.1965 à/to 1973 incl.Montreal.1968, 1969, 1971, 1973 Montreal.1965 à/to 1968 incl., 1972 et/and 1973 Montreal .1965.1970 à/to 1973 incl.Granby.1965 à/to 1973 incl.Côte-St-Luc.1966 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.1965, 1968 à/to 1973 incl.Vimont.1965 à/to 1973 incl.Lachine.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1972, 1973 Wakefield.1967.1973 Montreal.1971 à/to 1973 incl.Montreal.1965 à/to 1973 incl.Côte-St-Luc.1969 à/to 1973 inol.Verdun.1966 à/to 1973 incl.Pointe-Claire.i96S à/to 1973 incl.Montreal.1970i ,972 1973 Montreal.1965.1966.1971 à/to 1973 incl. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974.106' année, n\" 4 8627 Nom de la compagnie Name of the company Adresse Address Rapports non produits Returns not filed Z.&.Z.INC.86269 ZACCARDELU INC.87799 TONY ZULLO CEMENT & STUCCO CONTRACTOR LTD.82029 St-Lambert.1965 à/to 1973 incl.Ste-Foy.1966 à/to 1970 incl., 1972 et/and 1973 Montreal.1968 à/to 1973 incl.59030-o Le directeur du seraice des compagnies, Pierre Desjardins.59030-q Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies Xame of the companies Dissolution Date Gazette officielle No Official Gazette No.ABITIBI METALS MINES LTD.(LIBRE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE)\t01\t06\t1974\t22 ACME SERVICES & MAINTENANCE LTD.\t22\t03\t1974\t12 ALCAN CLUB.LE CLUB ALCAN\t29\t12\t1973\t62 LE COMITE DES LOISIRS DE VAL ST-PIERRE.\t18\tOS\t1974\t20 LA JEUNE CHAMBRE DE GRANBY INC.\t22\t06\t1974\t25 LAFENICE RESTAURANT INC.\t08\t12\t1973\t49 J.ADRIEN ROLAND LEMIEUX INC.\t13\t10\t1973\t41 \t27\t07\t1974\t30 UNITED TOUCH FOOTBALL ASSOCIATION OF MONTREAL\t29\t12\t1973\t52 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution compagnies.of the said companies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir Consequently, the said companies, are considered as having jamais été dissoutes en vertu de ladite loi.sans préjudice aux never been dissolved under the said Act, without prejudice droits acquis par toute personne entre la dissolution et la to the rights acquired by any person between the dissolution révocation.and the revocation.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 5903O-O Pierre Desjardins.59030-O Director of the Companies Service. 8628 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1971,, Vol.100, No.46 Compagnies \u2014 Loi des Companies Act Lettres patentes (l,e partie) Letters Patent (Part D Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes constituant en corporation: The Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES AGENCES MELMARIBEC INC.1368-9047 AGENCES DE VENTE BARRY ZRYL INC.and its English version BARRY ZRYL SALES AGENCIES INC.1369-7651 AGENCE DE VOYAGE ROBILLARD INC.1369-9087 ALUMINUM DECARIA INC.1358-7902 LES AMUSEMENTS CARTIERVILLE INC.et sa version anglaise CARTIERVILLE AMUSEMENTS INC.1359-6721 LES AMUSEMENTS SIROIS LIMITEE____ 1359-6465 ASSURANCES RENE DUHAIME INC.1358-3547 ATELIER D'USINAGE ROCK INC.et sa version anglaise ROCK MACHINE SHOP INC.1359-7398 AUDAX INC.1370-0729 AUDET & AIRMAN.INC.1369-8204 799, rue Vachon, Lasalle.05 07 74 2266, Bourgoen, Saint-Laurent.21 10 74 AUTO FISKE INC.1359-2324 AUTOMOBILES PHILIP SANGUINET INC.and its English version PHILIP SANGUINET AUTOMOBILE INC.1369-9020 215.rue Notre-Dame, Repentigny .02 01 74 5391, rue Charleroi, Montréal-Nord .27 08 74 Montréal.15 10 74 Grande-Rivière.11 10 74 39, rue Jacques-Cartier, Salaberry-de- 07 08 74 Valleyfield Parc Mado, Saint-Georges.17 10 74 Case postale 312, Aylmer.16 10 74 4, Place Ville-Marie, Montréal.27 09 74 Dorval.19 09 74 1426, rue Bishop.Montréal.02 10 74 AUTOMOBILES SABREVOIS LTEE.et sa version anglaise SABREVOIS AUTOMOBILE LTD.1369-9988 BERNCAM LIMITEE.and its English version BERNCAM LIMITED 1369-9202 Sabrevois.10 74 Montréal 03 10 74 BOGIHAN INC.1359-3926 BOUTIQUE SANDRINE LTEE.1369-7305 191.rue St-Paul ouest, Montréal.26 09 74 Place Desjardins, Montréal.23 09 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 8629 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date BRASSERIE MUSKA INC.1359-5608 BUREAU D'INFORMATION ET DE GESTION (B.I.G.) INC.1356-5965 CAMPS TOURISTIQUES LA POINTE A DAVID INC.1358-9494 CAROSSERIE REAL ST-VINCENT INC.et sa version anglaise REAL ST-VINCENT AUTO BODY INC.1369-8816 CARROSSERIE KIAMIKA INC.1368-5722 LA COMPAGNIE DE RECREATION ET D'AMENAGEMENT NORFORD LTEE and its English version NORFORD RECREATION DEVELOPMENT COMPANY LTD.1359-0237 CONSTRUCTION CYRIL ST-GERMAIN INC.1369-1688 CONSTRUCTION PERFA LTEE .1359-4411 CONSTRUCTION R.RACICOT INC.1368-2207 CONSTRUCTION TRIANGLE MECANIQUE INC.et sa version anglaise TRIANGLE MECHANICAL CONSTRUCTION INC.1359-5145 LA CORPORATION EXPORT DU CANADA (1974) LTEE and its English version THE EXPORT CORPORATION OF CANADA (1974) LIMITED 1369-9178 CORPORATION LA FOURMILIERE.1370-1081 CREME GLACEE LUCIE LTEE .1359-4635 DEBELUX (QUEBEC) LTEE 1369-9939 DEMOLITION BAR INC.et sa version anglaise BAR DEMOLITION INC.1370-0257 DEMOLITION POINTE-AUX-TREMBLES INC.et sa version anglaise POINTE-AUX-TREMBLES DEMOLITION INC.1369-9814 DEPANNAGE DONAT INC.1358-2473 DIFFUSION BOREALE LTEE 1359-5129 DUSONIC INC.1370-0042 9104, boulevard Ste-Anne.Sainte- 07 10 74 Anne-de-Beaupré Saint-Eustache.15 05 74 Maniwaki.03 09 74 Saint-Vincent-de-Paul.01 10 74 835, Marie-Victorin, Contrecoeur Orford.07 06 74 09 09 74 715, rue Lambert, Saint-François, 31 07 74 Laval Pointe-Gatineau.30 09 74 647, rue Montcalm, Longueuil.13 05 74 169, rue Henri-Dunant, Laval.03 10 74 6570, rue Cartier.Montréal.11 10 74 3788, rue Marian, Fabrev ille, Laval .22 10 74 969, boulevard Décarie, Saint-Laurent 01 10 74 1155, boulevard Dorchester, suite 818, 10 10 74 Montréal 2310, rue Ste-Marguerite, Longueuil.15 10 74 Pointe-aux-Trembles.08 10 74 3846, Notre-Dame, Chomedey, Laval.01 08 74 Québec.03 10 74 Montréal.10 10 74 8630 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971,, Vol.106, No.16 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ECURIES R.O.R.LTEE.and its English version R.O.R.STABLES LTD.1369-9344 LES EDITIONS O.M.D.C.INC.1358-1509 EDITIONS PRISME INC.1369-7073 L'ENTREPOT DU PETIT GEANT LTEE.and its English version LITTLE GIANT WAREHOUSE LTD.1370-1057 LES ENTREPRISES ATLANTE INC.et sa version anglaise ATLANTE ENTERPRISES INC.1369-7081 LES ENTREPRISES COMMERCIALES PYRRALIS LTEE.and its English version PYRRALIS COMMERCIAL ENTERPRISES LTD.1370-0315 LES ENTREPRISES D'HOTELLERIE DUQUETTE INC.1357-4074 ENTREPRISES J.R.GODBOUT INC.et sa version anglaise J.R.GODBOUT ENTERPRISES INC.1359-8453 ENTREPRISES LASSON INC.et sa version anglaise LASSON ENTERPRISES INC.1369-6646 LES ENTREPRISES PATRICK COTE INC.1359-8156 EQUIPEMENT DE BUREAU QUEBEC METROPOLITAIN INC.1359-9485 EQUIPEMENT J.M.INC.et sa version anglaise J.M.EQUIPMENT INC.1358-6276 EXCAVATION DEUX-MONTAGNES INC.1369-6422 EXCAVATIONS R.BEAUDOIN & FILS INC.1359-5160 FERME F.BRODEUR INC.et sa version anglaise P.BRODEUR FARM INC.1369-9103 FERME VALMORE TRUDEL INC.1359-6846 FONDERIE MASKA INC.et sa version anglaise MASKA FOUNDRY INC.1359-3389 LEVIS GAGNE INC.1359-8099 1739, chemin d'Aoust, Saint-Lazare .03 10 74 467, Bellevue, Laval.14 08 74 217, rue Principale.Saint-Basile-le- 19 09 74 Grand Québec.22 10 74 Montréal.19 09 74 1, Place Ville-Marie, suite 1734, 15 10 74 Montréal.Mont-Laurier.09 09 74 845, boulevard Marie-Victorin, Saint- 22 10 74 Nicolas.771, rue Ogilvy, Montréal.09 10 74 Ancienne-Lorette.21 10 74 Québec.28 10 74 5775.avenue Victoria, suite 237, 19 08 74 Montréal.380, 3e Avenue, Deux-Montagnes.12 09 74 Saint-Georges-Ouest.Q3 10 74 7730.18e Avenue, Montréal.02 10 74 J0liet,e.16 10 74 Sainte-Claire-de-Dorchester.26 09 74 Victoriaville.21 1Q \u201e GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 197A, 106' année.n° L6 8631 Incorporation Siège social / Head Office Date Aima.03 10 74 Saint-Faustin.03 10 74 240, rue Elm, suite 212, Saint-Lambert 23 09 74 Laval.26 09 74 4482, delà Promenade, Saint-Antoine- 21 10 74 de-Tilly.44, Port Royal ouest, Montréal.21 10 74 Saint-Hubert.30 09 74 2795, Péribonka, Lava!.21 10 74 Sainte-Martine.30 09 74 Laval.18 07 74 989, rue Melville, Quartier Chomedey, 15 10 74 Laval.4005, rue Richelieu, Montréal.06 09 74 Sainte-Julie.20 09 74 100, Place Charles-Lemoyne.17 07 74 suite 226, Longueuil.6313, Belherbe, Saint-Léonard.27 09 74 Contrecoeur.06 05 74 Ancienne-Lorette.04 07 74 53, Goineau, Pont-Viau, Laval.10 10 74 Saint-Timothée.15 08 74 1571, rue Berry, Orsainville.24 10 74 1, rue Levasseur, Victoriaville.29 10 74 Nom / Name LUCIEN GAGNON & FILS INC.1359-5)52 GARAGE J.DELISLE INC.1359-5079 GARAGE R.JEAN LTEE.et sa version anglaise K.JEAN GARAGE LTD.1369-7602 GERVAL INC.1359-3975 GESTION D.V.G.INC.1359-7943 GESTION LABROSSE INC.et sa version anglaise LABROSSE HOLDING INC.1370-0893 HOTELLERIE LA GRANDE INC.1369-5887 LES IMMEUBLES COLA INC.and its English version COLA REALTIES INC.1359-8115 IMMEUBLES JODOIN LTEE.1369-6455 LES IMMEUBLES VILLIARD INC.1357-9412 IMPORTATION-EXPORTATION CONTACT CANADA INC.1359-6754 IMPRIMERIE JONES LAM-THO LTEE.and its English version JONES LAM-THO PRINTING LTD.1369-5713 INFORMATION STE-JULIE ET ST-AMABLE LTEE.1359-2423 INTERCONCEPT INC.1369-0466 LES INVESTISSEMENTS Y VAN LECLERC INC.1369-8287 PAUL JACQUES & FILS INC.1358-6599 JALOMA INC.1357-6301 LES JEUX O.K.O.(1974) INC.1359-6259 ROBERT LALONDE ET FILS INC.1358-5930 PATRICK LATULIPPE INC.1359-0039 LOUIS LEVASSEUR LTEE.1359-9618 8632 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date Montréal.LIBRAIRIES S.N.A.P.(QUEBEC) LTEE.et sa version anglaise S.N.A.P.BOOKSELLERS (QUEBEC) LTD.1369-8956 LOCATION D'AUTO EMPIRE INC.and its English version EMPIRE AUTO RENTALS INC.1358-0328 LOCATION B.L.P.LTEE.216, Octave-Crémazie, Boncherville .et sa version anglaise B.LP.LEASING LTD.1357-4413 02 10 74 LE LOGIS FUTURISTE DE LA BEAUCE INC 1359-6697 LUMINAIRE BEDARD INC.1358-7894 L'UNIQUE, RESSOURCES HUMAINES INC.1359-6473 MACHINES M.D.G.INC.and its English version M.D.G.MACHINERY INC.1358-4891 MAGASIN MICHAELS INC.and its English version MICHAELS' SHOPPE INC.1369-8303 MARCHE D'ALIMENTATION L.B.INC.1369-9855 MARCHE CHOI LTEE____ and its English version CHOI'S MART LTD.1357-7069 MEUBLES CARTIER INC.1359-7331 MEUNERIE SAWYERVILLE INC.1359-7935 MODE CLARA INC.et sa version anglaise CLARA MODE INC.1368-3446 MOTEL ABITIBIEN INC.1359-4601 PALMER & BERGERON INC.1357-6418 PIECES D'AUTOS JOMPHE INC.1359-5210 PLACAGE ST-MICHEL INC.et sa version anglaise ST-MICHEL PLATING INC.1369-8659 PLOMBERIE DUMOULIN ET FRENETTE INC.1369-9194 PRET A PORTER CAPUCINE INC.1369-8881 6820, avenue Marconi, Montréal.06 09 74 26 09 74 11 10 74 02 10 74 11 10 74 13 08 74 35.Place Bilodeau, Val-Bélair.Lévis.Sainte-Foy.Montreal.Dollard-des-Ormeaux.27 09 74 4846, boulevard Gouin est, Montréal .40-54, avenue Evangeline, Granby.Rivière-du-Loup Sawyerville.767, boulevara Taschereau, Greenfield Park Robertson et Pope.6, rue Cookshire, East Angus.Havre-Saint-Pierre.3400, boulevard Métropolitain est, Montréal Val-d'Or.Montréal 09 10 74 10 07 74 16 10 74 21 10 74 21 05 74 01 10 74 09 09 74 04 10 74 30 09 74 03 10 74 01 10 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1974.106' année, n° 46 8633 Nom I Name Siège social / Head Office Incorporation Date PRODUITS HYDRAULIQUES DIXIE INC.et sa version anglaise DIXIE HYDRAULIC PRODUCTS INC.1369-7479 QUINCAILLERIE LAFONTAINE INC.1369-3700 REGRIGERATION FIXAIR INC.1370-0240 REFRIGERATION GASPE INC.1358-6508 REN-NAND INC.1369-9756 RESTAURANT COLLIBRI INC.1359-2142 RESTAURANT IL ETAIT UNE FOIS UN FOURNEAU INC.and its English version ONCE UPON AN OVEN RESTAURANT INC.1370-0323 RESTAURANT JARRY (1974) INC.and its English version JARRY RESTAURANT (1974) INC.1368-8650 RESTAURANT P.E.M.LTEE.and its English version P.E.M.RESTAURANT LTD.1369-9251 RESTAURANT PALAIS DU GOURMAND LTEE.1370-0778 RESTAURANT PARASOL INC.1369-4591 RODAGE DE SOUPAPE MONTREAL LTEE .and its English version MONTREAL VALVE RESEATING LTD.1368-0699 SALON DE BEAUTE RALPH.O'HANA INC.1369-7420 SCIERIE BEAUMONT INC.1359-5871 SERVICE D'ENTRETIEN R.A.L.INC.1369-7776 LES SERVICES DE RECLAMATIONS JEAN HEBERT INC.1359-8222 SERVICE DE VENTE A L'ENCAN R.P.M.LTEE 1369-1589 L.SIMONEAU ET FRERES INC.1369-9806 SOCIETE DE GESTION NASO INC.and its English version NASO HOLDINGS INC.1369-7461 SOCIETE DE GESTION S.R.and its English version S.R.HOLDING CORPORATION 1369-7760 8850, Champ-d'Eau, Saint-Léonard.23 09 74 283, boulevard Des Hauteurs, 16 10 74 Lafontaine Montréal.15 10 74 Gaspé.19 08 74 1115 Sherbrooke ouest, suite 1605, 18 10 74 Montréal 167, rue Principale, Saint-Thomas- 18 09 74 d'Aquin 6211, chemin Côte St-Luc, Montréal .15 10 74 6549, rue Jarry est, Saint-Léonard .03 07 74 173, avenue Van Home, Montréal.03 10 74 Montréal.18 10 74 53, rue Victoria, Valleyfield.26 08 74 8305, rue Durocher, Montréal.02 05 74 Montréal.23 09 74 185, des Erables, Sainte-Catherine .08 10 74 Laval.24 09 74 3509, boulevard de la Concorde, app.21 10 74 205, Laval Montréal.30 07 74 Montréal.08 10 74 3800, rue St-Patrick, Montréal.07 10 74 5156, Sherbrooke ouest, suite 419, Montréal 24 09 74 8634 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1911,.Vol.106.No.1,6 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LA SOCIETE IMMOBILIERE DES SOURCES INC.1359-0054 SOCIETE KAENEL INC.1369-9350 SONOMED INC.1369-6224 SOUDURE ET ERECTION MARTIN INC.et sa version anglaise MARTIN WELDING A.ND ERECTION INC.1370-0265 LE SPA SILHOUETTE LONGUEUIL LTEE.and its English version SILHOUETTE SPA LONGUEUIL LTD.1369-8980 STENAJEAN INC.1369-9947 SUPERMARCHE VAL-DAVID INC.1369-2413 SYSTEME DE FREINS ET D'EMBRAYAGE BERNIER (1974) INC.et sa version anglaise BERNIER BRAKE AND CLUTCH (1974) INC.1369-7511 TAVERNE A.SENECAL INC.1358-2903 TERRASSE CHANTAL INC.1368-3545 THERIAULT.AHIER & ASSOCIES INC.1359-7687 TRANSPORT ROBERT RICHER INC.et sa version anglaise ROBERT RICHER TRANSPORT INC.1369-7552 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE REVETEMENT ST-BRUNO INC.and its English version ST.BRUNO LANDSCAPE AND ASPHALT INC.1369-5291 TREMPAC INC.1359-6143 TRIAC INC.1359-6432 2700.boulevard Laurier, suite 613, 05 09 74 Sainte-Foy 3225, avenue Ridgewood, app.201.04 10 74 Montréal Montréal.H 09 74 240, 1ère Avenue, Terrebonne.15 10 74 Longueuil.02 10 74 PAULINE VINCENT INC.1369-9368 VOYAGES PAN EUROPE INC.et sa version anglaise PAN EUROPA TRAVELS INC.1369-6315 LES VOYAGES XENIA LTEE and its English version XENIA TOURS LTD.1359-4776 12180, Henri-Beau, Cartierville.10 10 74 1855, route 11, Val-David.06 08 74 8774, rue Boyce, Montréal.23 09 74 1174, Ste-Catherine est, Montréal.05 08 74 142, De Picardie, Saint-Lambert.28 06 74 78.Place Bilodeau.Val-Saint-Michel .18 10 74 Montréal.18 10 74 Montréal.03 09 74 1036, Dijon, Sainte-Foy.10 10 74 Cap-de-la-Madeleine.H 10 74 280, rue Bleignier, Saint-Laurent.04 10 74 615, boulevard Dorchester ouest, 11 09 74 suite 1010, Montréal 11!.ngr'i»Stf\"Patherine ouest'suite 01 10 74 208, Montréal 59030-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardin6.59030-o Pierre Desjardins, \u2022r of the Companies Service. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 46 8635 Lettres patentes (3e partie) Letters Patent (Part III) Le ministre de» institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions.Companies and cooperatives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date ASSOCIATION DES BIENFAITEURS MARIE REINE DES COEURS INC.et sa version anglaise MARY QUEEN OF HEARTS ASSOCIATION OF BENEFACTORS INC.1369-3494 ASSOCIATION DES ETUDIANTS ADULTES DE LA REGION 6 1369-9376 ASSOCIATION SPORTIVE LES AMBASSADEURS DE BOISBRIAND INC.1369-3411 LE CENTRE AMICAL DE JONQUIERE INC.1359-8024 CLUB D'EQUITATION MEGANQUESTRE INC.1356-8126 CLUB DE LOISIRS CANTINE MOBILE DE MONTREAL INC.1369-7222 2501.rue Walkley, Montréal.28 08 74 CLUB MOTO-NEIGE LES TIGRES.1369-7067 CLUB OPTIMISTE ST-COME LINIERE INC.1354-9092 CLUB SOCIAL DE LA BONNE ENTENTE DES EMPLOYES DE LA COMPAGNIE J.J.JOUBERT LIMITEE 1357-6210 CLUB SOCIAL X.M.DU NORD, INC.1359-4494 COMITE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE BOISCHATEL 1359-6572 FEDERATION DES CLUBS DE L'AGE D'OR DES ILES-DE- LA-MADELEINE 1359-4452 LES JEUNES ENTREPRISES DE SAINT-JEAN-IBERVILLE- ST-LUC 1359-0336 LA LIGUE DE TAXIS DE ST-EUSTACHE INC.1359-7927 MOUVEMENT RECREATIF MARICOURT.1359-5475 LA SOCIETE D'ORIENTATION DE ST-FRANÇOIS-D'ASSISE.1369-4138 666.Champagneur, Local 215, Outremont.29 10 74 999, rue Grande-Allée, Boisbriand.14 08 74 Jonquière.21 10 74 Route Rurale numéro 1, Lac-Mégantic 17 10 74 200.rue Norman.Saint-Pierre.20 09 74 Saint-Lambert.16 10 74 Saint-Côme-de-Kennebec.16 03 74 Montréal.03 07 74 Chicoutimi.11 10 74 61.rue Tardif.Boischàtel.11 10 74 Cap-aux-Meules.Iles-de-la-Madeleine.30 09 74 Saint-Jean.09 09 74 352, rue Féré, Saint-Eustache.21 10 74 3545, Prince-Charles, Saint-Hubert .04 10 74 1595, rue St-Hubert.Montréal.21 08 74 59d30-O Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.59030-O Pierre Desjardins.Director of the Companies Service. sivm; QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Notembtr /.Le directeur du service de» compagnie», 59030-o Pierre Desjardins.Note: These notices published in the Québec Officiai Gazelle dated November 2, 1974, (number 44) should have been published under the heading \"Letters Patent Part IH\"insteadof under \"Letters Patent Part I\".Pierre Desjardinb.59030-o Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires i: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Change» THOMAS C.COLLINS, SON & CO.LTD.1111-4956 27 04 61 LES DISTRIBUTIONS A.B.INC.06 10 70 4341-70 J.A.DROLET LTEE.21 12 40 9257-49 LES EQUIPEMENTS TRACTION INC.21 07 65 28 08 74 1.Modifiant le capital / Altering the capital.2.Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restriction».17 06 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes/ Amending certain provision» of the letters patent.11 09 74 Modifiant certaines dispositions des lettres patentes/ Amending certain provisions of the letters patent.20 09 74 Ancien nom / Former name: JOS MORIN & FILS LTEE GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 197A, 106- année, n° A6 8637 Fusion de compagnies Amalgamation of companies Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a accordé des lettres patentes autorisant la fusion de : panies Act, he has granted letters patent authorizing the amalgamation of: Nom de la nouvelle compagnie Name of new company Siège social Head office Fusion Amalgamation Date Nom des compagnies fusionnées Names of companies amalgamated LES BREUVAGES LOUIS VIGNEAULT LTEE 1359-1763 LES PLACEMENTS FRAN-RAY INC.et sa version anglaise FRAN-RAY INVESMENTS INC.1358-3059 Sept-Iles.09 10 74 LES BREUVAGES LOUIS VIGNEAULT LTEE LOUIS VIGNAULT LTEE Suite 609, 50, Crémazie ouest, Montréal.01 08 74 LESCALE HOLDINGS CO.LTD.LESCALE INVESTMENTS LTD.FRAN-RYE INVESTMENT CORPORATION ARNEL CONSTRUCTION CO.LTD.59030-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.59030-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changea LES ETALAGES M.ROSS (ONTARIO) LTEE 18 01 71 13 09 74 1.Ancien nom/ Former name.¦ and its English version LOCUS DESIGNS LTD.M.ROSS DISPLAYS (ONTARIO) LTD.2.Modifiant les pouvoirs' Modidying the 5184-70 powers.FOOD SERVICES LIMITED .01 03 63 21 10 74 Modifiant les dispositions des lettres paten- 898-63 tes/ Amending the provisions of the letters patent.LES GALERIES DE LA CHAUDIERE INC.24 01 74 09 10 74 Ancien nom/ Former name: 740366 LES GALERIES STE-MARIE INC.LES INDUSTRIES PHILIAS FLAMAND 06 03 58 24 10 74 Modifiant.le capital/ Altering the capital.LIMITEE 10806-58 McLEAN MANAGEMENT LTD.12 02 59 15 07 74 Modifiant le capital/ Altering the capital.10714-59 PANECO INCORPOREE.01 02 71 11 07 74 Etendant les pouvoirs / Extending the pow- 490-71 ers.LES PILOTES DU ST-LAURENT CENTRAL 15 08 73 12 09 74 Modifiant.les pouvoirs / Modifying the pou- INC.ers.733602 LES PLACEMENTS LAMBTON INC.24 01 73 11 10 74 Etendant les pouvoirs/ Extending the powers.LES PLACEMENTS ROBERT CARON INC.08 10 69 11 10 74 1.Modifiante capital/ Altering the capital.4830-69 2.Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.SUPERMARCHE L.R.L.INC.15 05 73 25 10 74 Ancien nom/ Foremr name: 732230 SUPERMARCHE MERITE (1973) INC.Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins, 59030-o Pierre Desjardins.59030-o Director of the Companies Service. m;;;s QUÉBEC OFFICIAI.OAZETTE.Xoreuiber 16.1971, Vol.106.Xo.16 Domirile légal (Article 30) Legal Domicile (Section 30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose names follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address AGENCES JEANNINE McCARTHY LTEE J BAN NINE MCCARTHY AGENCIES LTD.4990-67 AIRD MANAGEMENT CORPORATION .13529-62 ALLIED LEATHER COMPANY .1109-4588 ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU LAC MAGOG 4274-70 BEAULIEU SUPER MARKET INC.12865-58 BIJOUX C.L.R.LTEE.C.L.R.JEWELS LTD.737906 BOUTIQUE CHARL.FLEURISTE.INC.T-i-W-â BROWN SALES INTERNATIONAL INC.845-69 NINA CARD Y INC.1111-7686 R.CHIQUETTE & FILS INC.13138-54 CIVIC PARKING CENTRE LTD.14973 61 CLUB AUX PIERRES .C.C.P.12-41 CLUB DE CHASSE ET DE PECHE DES NEUF LACS C.C.P.7-07 CLUB GIGOT.C.C.P.72-56 LE CLUB KIWANTS DE LA BAIE DES HA! HA! INC.560-69 CLUB L'ECUREUIL.CCP: 61-55 CLUB NEMROD INC.CCP: 80-60 LA CONFEDERATION QUEBECOISE DU PLEIN AIR 622-69 22 11 67 2121, de Salaberry.Montréal.1401.rue Legendre ouest, suite 303.Montréal.12 09 62 Montréal.2635.rue Aird, Montréal.04 12 57 Montréal.34S8, Côte des Neiges, bureau 608, Montréal.15 06 71 Deauville.436.rue Park, Deauville.15 08 58 9125, boulevard Pie IX, 1978.rue Parthenais, Montréal.Montréal.20 08 73 Saint-Bruno-de-Montar- 46, rue Clairevuc, Saint-ville.Bruno-de-Montarville.27 08 73 Sainte-Agathe .60A.rue Principale.Sainte-Agathe.27 02 69 1400.rue Metcalfe, 1, Arvida.Mart \u2022 A >, Montréal.Place Bonaventure, Montréal.18 09 68 620, Cathcort, Montréal .1401.Legendre ouest, suite 303, Montréal.18 12 54 Québec.416.rue de la Reine, Québec.13 10 61 615 ouest, boulevard 2015.rue Drummond, Dorchester, bureau 630.bureau 666, Montréal.Montréal.09 05 41 Shawinigan.653.avenue des Cèdres.Shawinigan.26 04 07 Saint-Siméon.Saint-Siméon.26 09 56 Saint-Jean .486.rue St-Joseph, Saint- Jean.23 04 69 Bagotville.516, rue Victoria, Bagotville.25 05 55 Trois-Rivières.1748, rue Dumoulin, Trois-Rivières.09 08 60 Roberval.613.avenue Boivin, Roberval.02 01 70 Montréal.455.rue St-Jean.Montréal. GAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 8639 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie - Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address LES CONSEILLERS CADREX INC.18 12 70 Québec.600, avenue Laurier.CADRBX CONSULTANTS INC.suite 201, Québec.5570-70 CONSTRUCTION FAIRWAY INC.13 06 60 Montréal.5858, chemin Côte des 1118-3589 Neiges, bureau 612, Montréal.W.J.COSGROVE & ASSOCIES INC.03 05 71 3300, Cavendish, 2600, rue Ontario est.2288-71 bureau 580, Montréal.bureau 220, Montréal.MAURICE DAVIAU A: ASSOCIES INC.16 05 67 3009.boulevard de la 815.Salaberry.Laval.1346-67 Concorde.Laval.DELUX GOLD JEWELRY MFG.CO.LTD .15 09 70 2442.Ekers, Montréal .5493, avenue Durocher.4088-70 Montréal.M.DENONCOURT & FILS INC.22 08 74 Saint-Tite.240.route 153, Saint-Tite 1358-6557 DOUALEX INC.27 06 74 Baie-Comeau.45, rue de Rouville, 1357-5352 Baie-Comeau.DU-RAY NOUVEAUTES INC.24 05 68 1005, rue Morisson, Saint- 375, rue Milette.Saint- DU-RAY NOVELTIES INC.Hyacinthe.Hyacinthe.1133-68 LES ENTREPRISES DE RESTAURATION 15 07 74 1101, Parc Lafontaine.3674.rue St-Denis, L.K.G.LTEE Montréal.Montréal.1369-0003 EVER-REDDY DUPLICATING SERVICE INC.21 03 55 Montréal.1010.rue Stc-Catherine 10657-55 ouest, suite 10, Montréal.EZRA CORPORATION.14 11 57 2.Edison, Place Bonaven- 1450, City Councillors, 13559-57 ture, Montréal.Montréal.FORESIGHT DEVELOPMENT INC.06 11 69 Saint-Laurent.997.boulevard Décarie, 5174-69 Saint-Laurent.GASPE AUTO PARTS INC.31 05 71 Gaspé.rue Jacques-Cartier, Gaspé.2887-71 LES GESTIONS KOYO LTEE.04 03 74 Montréal .4667, avenue Hickmore, A'OFO HOLDINGS LTD.Montréal.1367-3504 HABITAT VAL ORFORD INC.07 11 73 10480.boulevard Lajeu- 7779, rue Casgrain.734915 nesse.Montréal.Montréal.HAGO UNDERWEAR MFG.LTD.16 02 65 Montréal.77, rue Mont-Royal ouest.1115-8151 Montréal.THE HERBERT CORPORATION.21 06 65 145.Bates, Mount Royal 5490, avenue Royalmount, 2897-65 suite 205, Mount Royal.LES IMMEUBLES J.G.L.INC.10 04 70 Montréal.2235, rue Sherbrooke est, 1543-70 Montréal.INTEGRON ASSOCIATES INCORPORATED.06 02 68 Montréal.3445.rue Drummond.523-68 sulte 1102, Montréal.INTERNATIONAL SECRETARIAL SERVICE 11 06 68 Montréal.1015 Beaver Hall, INC.Montreal.2694-68 LA LAITERIE DE SHERBROOKE LIMITEE .03 03 50 Sherbrooke.558, rue Woodward, 2750-50 Sherbrooke.LINCOURT & CAYER INC.23 02 73 90, rue St-Joseph, 1104.boulevard Labelle.730831 Blainville.Blainville. Mi III QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie -' Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address L'OPTIQUE SHERBROOKE INC.SHERBROOKE OPTICAL INC.2023-69 29 04 69 230, rue King ouest, Sherbrooke.LYNCH LAKE CLUB CCP: 16-46 18 04 46 Fort Coulonge.SERVICES DE CHAUFFEURS BISON INC.BISON DRIVER SERVICES INC.1367-7448 LYON INDUSTRIES LTD.30 LES INDUSTRIES LYON LTEE 5291-66 M.B.S.CONSTRUCTION INC.08 714909 THE MARTINIQUE MOTOR INN LTD.21 MOTEL LE MARTINIQUE LTEE 1113-4772 MATTEAU RADIO ELECTRIQUE LTEE.24 46282-53 MERCERIE LAFLEUR INC.16 5657-70 METROPOLITAN CLEANERS INC.13 04 1722-65 MODES BEL AGE INC.14 08 724530 NADEAU CONSTRUCTION INC.28 1117-9215 LES PETROLES JACQUES-CARTIER INC.04 07 JACQUES-CARTIER PETROLEUM INC.2935-67 11 65 Montréal.71 5900.rue Marceau, Pierrefonds.63 1005.rue Guy.Montréal 53 1365.rue St-François- Xavier, Trois-Rivières.13, Wellington nord, Sherbrooke.R.W.Aston, c/o Soucie Brothers Garage, Fort Coulonge.9600.rue Meilleur.Montréal.4870, rue Nanterre, Pierrefonds.1.Place Ville-Marie, suite 3436, Montréal.2391, Place de Vaudreuil.Trois-Rivières.12 70 Sherbrooke.170, rue Terril!, Sherbrooke.65 3606, Montée des Sources, Dollard-des-Ormeaux.72 9200.avenue du Parc, suite 501.Montréal.11 62 10705.Vianney, Montréal.67 2253, boulevard Tasche-reau, Longueuil.PLACEMENTS DEKA INVESTMENTS INC.12629-56 LES PLACEMENTS PAUL ROY INC.14 12 5279-67 PLACEMENTS TECO INC.26 06 2338-70 RESIDENCE LES CASCADES INC.04 04 1411-66 LES RESTAURANTS LA NOUVELLE ORLEANS INC.12259-62 20 08 66 Montréal.67 Montréal.70 850.rve Didace.M agog.66 Montréal-Nord.24 06 62 1005, rue Guy, Montréal.SELECT TRANSPORT INC.12 05 2269-65 66 10344, avenue Vianney.Montréal.09 04 74 Montréal.SERVICE D'OUTILS ELECTRO-AIR INC.17 07 1357-9123 SIKH AS CORPORATION.01 08 13698-61 SOMERLED HOLDINGS LTD.13 07 1118-3936 74 580.Grande-Allée est.suite 140, Québec.61 3495, Mountain, suite 404, Montréal.53 Montréal.4605, rue Sources, Dollard-des-Ormeaux.7080, rue Hutchison.Montréal.10230.rue De Lorimier.Montréal.27.rue St-Cbarles ouest, Longueuil.500, Place d'Armes, suite 1200, Montréal.5100.des Mélèzes.Montréal.1240.rue Merry sud.Magog.3461, boulevard Gouin est, Montréal-Nord.1, Place Ville-Marie, suite 3436, Montréal.8602.rue de Grosbois, Montréal.485, rue McGill, suite 202, Montréal.1165, St-Vallier ouest, Québec.455, rue Craig ouest, Montréal.4700.Prince of Wales, Montréal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 197A, 106' année, n° A6 8641 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Prenons address Nouvelle adresse Areu> address STATION DE SERVICE ROND-POINT INC.25 CIRCLE SERVICE STATION INC.738264 STUDIO DE PHOTO QUEBECOIS INC.16 721492 SUNNYDALE CLEANERS INC.14 4106-65 TAVERNE PARC EXTENSION INC.12 PARC EXTENSION TAVERN INC.2514-71 TERRITOIRE DE CONSERVATION 26 WALBRIDGE LIMITEE and its English version WALBRIDGE CONSERVATION AREA LIMITED 1368-8122 ADRIENNE THIBEAULT INC.30 681-67 VEILLET & GOSSELIN LIMITEE.12 VEILLET d- GOSSELIN LIMITED 14634-52 VEILLEUX CONSTRUCTION INC.14 4049-65 VILLE EMARD HOLDINGS LTD.19 10962-59 09 73 Saint-Laurent.1, boulevard Décarie, Saint-Laurent.03 72 Québec.394, rue du Roi, Québec.09 65 3606, Montée des Sources, 4605, rue Sources, Dollard-des-Ormeaux.Dollard-des-Ormeaux.05 71 Montréal.6900, rue du Parc, Montréal.06 74 Saint-Ignace-de-Stanbridge Village de Mystic, Saint- Ignace-de-Stanbridge.03 67 Chicoutimi.1, Place du Saguenay, Chicoutimi.11 52 Val-d'Or.1126, 8e Rue, Val-d'Or.09 65 Montréal.3105, rue St-Donat, Montréal.02 59 400, rue Ontario ouest, 50, rue Crémazie.app.956, Montréal.Montréal.Pierre Desjardins, 59030-O Director of the Companies Service.59030-O Le directeur du service des compagnies.Pierre Desjardins.Abandon de charte Surrender of Charter Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a accepté l'abandon de la charte de: panies Act, he has accepted the surrender of the charter of: Nom / Name Incorporation Date Dissolution Date LES ADMINISTRATIONS GRIMARD INC.716477 AGENCES BARON LTEE.BARON AGENCIES LTD.1661-64 ANGELIQUE FASHIONS INC.2108-68 ART TERRAZZO LTD.1118-0791 L'ASSOCIATION DU BETON DU QUEBEC INC.QUEBEC CONCRETE ASSOCIATION INC.12659-53 30 11 71 16 04 64 06 05 68 01 06 64 05 06 63 15 11 74 22 11 74 15 11 14 15 11 74 26 10 74 8642 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 197A, Vol.106, No.16 Incorporation Dissolution Nom / Name Date Date BLH COMPAGNIE LIMITEE.23 12 65 22 11 74 BLH COMPANY LIMITED 5669-65 BEGIN SLATE INC.03 02 67 15 11 74 ARDOISES BEGIN INC.464-67 BIBLIOTHEQUE DES JEUNES DUVERNAY INC.25 01 63 15 11 74 321-63 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE LASALLE.01 04 63 22 11 74 LASALLE PUBLIC LIBRARY 1395-63 BOISVERT & CIE LTEE.11 08 59 01 11 74 14650-59 BONBONS VADIA LTEE.05 12 68 22 11 74 VADIA CANDIES LTD.5711-68 LE CACHET ROUGE INC.28 03 68 22 11 74 1430-68 JOS.CAMARDA INC.09 05 50 15 11 74 4019-50 CAMP D'EDUCATION PHYSIQUE GILLES HOUDE INC.20 09 65 16 11 74 4131-65 CAVALIER CAR WASH INC.02 08 67 15 11 74 LAVAGE D'AUTO CAVALIER INC.3196-67 CENBELGA HOLDINGS INC.10 01 61 16 11 74 10208-61 CENTRE DE DISTRIBUTIONS SOLEIL (C.D.S.) INC.14 09 72 15 11 74 725149 4177^AN IN°21 09 64 15 11 74 LBS CONSTRUCTIONS BUSQUE LTEE.28 09 67 22 11 74 CORDAY'S LTD.10 OK il i k i i 7a 1102-9164 .10 0b 41 15 11 74 DALE TRANSISTOR SERVICE LTD.,R ,, 7fl ,.,.5032-70 .lb 11 ,0 15 11 74 DOMTAR QUEVILLON LTD.«1 , tine corporation constituée suivant la Loi des compagnies et ayant son siège social flans la cité de Hull, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Le vice-président de la compagnie.59037-o S.j.RlTHERFOHD.J.P.BLAIS LIMITED Notice is hereby given that \"j.P.BLAIS LIMITED\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office in the City of Hull, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.S.j.Rutherford, 59037-o Vice-President of the company. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année.n* 46 S651 CAR v\\ ANE PLEIN-AIR J.G.INC.Avis est donné que la compagnie « CARAVANE PLEIN-AIR .J.G, INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, Gaétan' Fortin, notaire.67, Côte du Passage.Lévis.59038-0 CARAVANE PLEIN-AIR J.G.INC.Notice is given that \"CARAVANE PLEIN-AIR J.G.INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Gaétan Fortin, notary.Attorney for the company.67 Côte du Passage.Levis.5903S-o LES CONSTRICTIONS MICHEL GRAVEL INC.Prenez avis que la compagnie « LES CONSTRUCTIONS MICHEL GRAVEL INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 30 octobre 1974.Le procureur de la compagnie.Me André Hébert, notaire.538.Place St-Henri.Montréal.Québec.59040-o LES CONSTRUCTIONS MICHEL GRAVEL INC.Notice is given that \"LES CONSTRUCTIONS MICHEL GRAVEL INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions Companies and Coopeativcs for leave to surrender its charter.Montreal.October 30th, 1974.Mtrb André Hébert, Notary.Attorney for the company.538 Place St.Henri.Montreal, Québec.59040-o JEAN DORION INC.Prenez avis que la compagnie \u2022 JEAN DORION INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Baie-Comeau, ce 31 octobre 1974.Les avocats de la compagnie.Cloutier & Levasseur.22.Place La Salle, Baie-Comeau.Que.5904 l-o JEAN DORION INC.Notice is hereby given that \"JEAN DORION INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Baie-Comeau, October 31, 1974.Cloutier & Levasseur, Attorneys for the company.22 Place La Salle, Baie-Comeau.P.Q.59041-o RESIDENCE L'ESCAPADE INC.Avis est par les présentes donné que « RESIDENCE L'ESCAPADE INC.».une compagnie constituée sous l'autoiité de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal-Nord, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 18e jour d'octobre 1974.La secrétaire.59042-o Claire Laurin.THE ESCAPADE RESIDENCE INC.Notice is hereby given that \"THE ESCAPADE RESIDENCE INC.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal-Nord.will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 18th day of October, 1974.Claire Laurin, 59042-o Secretary.PELLETIER KARATE CLUB (DOJO) INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « PELLETIER KARATE CLUB (DOJO) INC.», corporation constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 15e jour d'octobre 1974.Le secrétaire.59043 Eileen Mundat.PELLETIER KAR VTE CLUB (DOJO) INC.Notice is hereby given that \"PELLETIER KARATE CLUB (DOJO) INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the pro\\ isions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 15th day of October, 1974.Eileen Munday, 59043-o Secretary. S652 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, av>.46 PROJET CEN'TREVILLE INC.« PROJET CEN'TREVILLE INC.» s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 7 octobre 1974.La secrétaire.59039-o Florence Colman.PLACEMENTS SENECAL INC.Avis est donné que la compagnie « PLACEMENTS SENECAL INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 18 octobre 1974.(Sceau) Le secrétaire, 59044-o Hector Bertrand.RAYMARCAN INC.Avis est par les présentes donné, que la compagnie « RAYMARCAN INC.», une corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social à Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, le 24 octobre 1974.Le procureur de la requérante.Me J.Jacques Hamel, ch.1681 est, rue Rachel, suite 27, Montréal, Que.59045-o CENTREMLLE PROJECT INC.\"CEN'TREVILLE PROJECT INC.\" will make an application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to surrender its charter.Montreal, October 7, 1974.Florence Colman, 59039-o Secretary.PLACEMENTS SENECAL INC.Notice is given that \"PLACEMENTS SENECAL INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, October 18, 1974.(Seal) Hector Bertrand, 59044 Secretary.RAYMARCAN INC.Notice is hereby given that the company \"RAY-MARC AN INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, said District, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, October 24th, 1974.Mb J.Jacques Hamel, q.c, Attorney for petitioner.1681 Rachel Street, suite 27, Montreal, P.Q.59045-o LA SOCIETE IMMOBILIERE PLACE ROYALE INC.Conformément aux dispositions de la Loi des compagnies, «LA SOCIETE IMMOBILIERE PLACE ROYALE INC.», donne par les présentes avis de son intention de demander au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte, l'annulation de sa charte et la dissolution de la compagnie.Montréal, Québec, ce 4c jour de novembre 1974.(Sceau) Le secrétaire, 59046-o Jean Bruyère.AUTOBUS ILE D'ORLEANS LIMITEE Prenez avis que la compagnie « AUTOBUS ILE D'ORLEANS LIMITEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, ce 25e jour d'octobre, 1974.La secrétaire, 59047-o Mme Carmen L.Dufour.LA SOCIETE IMMOBILIERE PLACE ROYALE INC.L'nder the provisions of the Companies Act, \"LA SOCIETE IMMOBILIERE PLACE ROYALE INC.\" hereby gives notice that it intends to apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender the charter of the Company, for cancellation of the charter and for the dissolution of the company.Montreal, Québec, this 4th day of November, 1974.(Seal) Jean Bruyère, 59046-o Secretary.AUTOBUS ILE D'ORLEANS LIMITEE Notice is hereby given that \"AUTOBUS ILE D'ORLEANS LIMITEE\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Vanier, Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 25th day of October, 1974.Mrs.Carmen L.Dufour, 59047-o Secretary. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971.106' année, n° 16 8653 BOULANGERIE ROSEMONT (1966) INC.Avis est par les présentes donné que « BOULANGERIE ROSEMONT ( 1966) INC.», corporation constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, ce 10e jour d'avril.1974.Le secrétaire, 59048-o jules durivage.BOULANGERIE ROSEMONT (1966) INC.Notice is hereby given that \"BOULANGERIE ROSEMONT (1966) INC.\".a corporation incorporated under the Companies Act, and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter according to the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 10th day of April, 1974.Jules Durivage, 59048-o Secretary.BOULANGERIE VIAU LTEE Avis est par les présentes donné que « BOULANGERIE VIAU LTEE ».corporation constituée en vertu (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.II \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande de permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.IH \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).rV \u2014 Avis de désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac, \u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de-choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972.ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amend-ments).These headings are identified as follows: I \u2014Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.HI \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 100' année.n° 46 8659 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) c) vérification de permis d) annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.e) * permis spéciaux.* Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.* In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trucking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rai- Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 Q 000001 M 100001 Q 100001 M 200001 Q 200001 M 300001 Q 300001 M 400001 Q 400001 M 500001 Q 500001 M 600001 Q 600001 M 700001 Q 700001 M 800001 Q 800001 M 900001 Q 900001 à M 002000 à Q 001000 à M 103000 à Q 102000 à M 210000 à Q 205000 à M 303000 à Q 302000 à M 402000 à Q 401000 à M 504000 à Q 503000 à M 601000 à Q 600500 à M 700500 à Q 700500 à M 800500 à Q 800500 à M 900500 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage ,' Québec regular transportation \u2014 trucking 8660 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1971, Vol.106, No.16 MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal bulk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Quebec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Québec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rail QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail IA \u2014 Avis de désistement: La Commission donne avis du désistement des requêtes par les requérants dans les affaires suivantes: QDW-91 Dossier: Q-500053-D-001 ESCAVATrOX DESGAGNÉ 36, rue Toussaint Québec 5, (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de Escavation Desgagné.QDW-92 Dossier: Q-503320-D-O01 LIONEL PERRON 35S, Bon Pasteur Matane, Comté Matane (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de Lionel Perron.QDW-93 Dossier: Q-500960-D-O03 .1.L.P.BRETON INC.\u2022519, rue Hermine Québec 2 (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de J.L.P.Breton Inc.QDW-91 Dossier: 500960-D-004 \u2022F.L.P.BRETON INC.519, rue Hermine Québec 2 (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis \u2022le camionnage en vrac de .1.L.P.Breton Inc.IV \u2014 Notice of withdrawal: The Commission gives notice of withdrawal of applications by the applicants in the following proceedings: QDW-91 File: Q-500053-D-001 ESCAVATION DESGAGNÉ 36 Toussaint Street Québec 5, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by Escavation Desgagné.QDW-92 File: Q-503320-D-001 LIONEL PERRON 358 Bon Pasteur Matane, County of Matane, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by Lionel Perron.QDW-93 File: Q-500960-D-003 J.L.P.BRETON INC.519 Hermine Street Québec 2.P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by J.L.P.Breton Inc.QDW-94 File: 500960-D-004 ¦I.L.P.BRETON INC.519 Hermine Street Québec 2, P.Q.i Withdrawal in the matter of the application for a hulk trucking permit by J.L.P.Breton Inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 novembre 1971, 100' année, n° 10 8661 QDW-95 Dossier: Q-Ô00960-D-005 .1.L.P.BRETON INC.519.rue Hermine Québec 2 (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de J.L.P.Breton Inc.QDW-96 Dossier: Q-500960-D-006 .1.L.P.BRETON INC 519, rue Hermine Québec 2 (Que.) Désistement dans l'affairés de la demande de permis de camionnage en vrac de J.L.P.Breton Inc.QDW-97 Dossier: Q-500960-D-O07 .1.L.P.BRETON INC.519, rue Hermine Québec 2 (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de J.!.P.Breton Inc.QDW-98 Dossier: Q-504625-S-001 DENIS LEYESQUE RR no 2 Ste-Angèle-de-Mérici Comté Rimouski (Que.) Désistement dans l'affaire de la demande de permis de camionnage en vrac de Denis Lévesquc.QDW-99 Dossier: 24007-V-D-l Me MARC CANTIN FLYNN, RIVARD, JACQUES.CIMON.LESSARD, LEMAY, avocats 2.avenue Chauveau CP.670, Haute-Ville Québec 4, G2R 4S6 Désistement dans l'affaire de la demande de permis de Bertbier Gagnon, voiturier-remorqueur el Speedway Express Ltd.voiturier-rouliei.QDYY-100 Dossier: Q-202032 BERTRAND CORMIER Lourdes-du-Blanc-Sablon Comté Duplessis Désistement dans l'affaire de la demande de permis de taxi de Bertrand Cormier.59032-o QDW-95 File: Q-500960-D-005 J.L.P.BRETON INC 519 Hermine Street Québec 2, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by J, L.P.Breton Inc.ADW-96 File: Q-500960-D-006 J.L.P.BRETON INC.519 Hermine Street Québec 2, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by J.L.P.Breton Inc.QDW-97 File: Q-500960-D-007 J.L.P.BRETON INC.519 Hermine Street Québec 2, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by J.L.P.Breton Inc.QDW-98 File: Q-504625-S-001 DENTS LEVESQUE R.R.No.2 Ste-Angèle-de-Mérici County of Rimouski, P.Q.Withdrawal in the matter of the application for a bulk trucking permit by Denis Lévesque.QDW-99 File: 24007-V-D-l Me MARC CANTIN FLYNN, RIVARD.JACQUES, CIMON.LESSARD, LEMAY.advocates 2 Chauveau Avenue Post Office Box 670, Haute-Ville Québec 4, G2R 4S6 Withdrawal in the matter of the application for a permit by Berthier Gagnon.haulaway operator, and Speedway Express Ltd.carrier.QDW-100 File: Q-202032 BERTRAND CORMIER Lourdes-du-Blanc-Sablon County of Duplessis Withdrawal in the matter of the application for a taxicab permit by Bertrand Cormier.59032-o 8662 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 I \u2014 Avis de la Commission * proprio motu » : La commission donne avis qu'elle entend décider des affaires suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.24 du Règlement 2.Quiconque désire être entendu doit faire connaître son intention dans les dix jours francs de la date de la présente publication.Rôle Q-2343 Q-200408-P-1 BRUNO BARIL 421, Notre-Dame Champlain, Comté Champlain .Que.) I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission: Tlie Commission gives notice of its intention to settle the following proceedings in conformity with the provisions of section 2.24 of Regulation 2.Whoever wishes to be heard must make his intention known within a period of ten clear days following the date of this publication.Aux fins de réviser la décision QPT-2339, en date du 8 octobre 1974, autorisant en faveur du requérant l'émission d'un permis de transport par véhicule-taxi dans la municipalité de Champlain, vu que ledit permis a déjà été autorisé en faveur de M.Wellie Gervais dans cette même municipalité.For the purpose of revising decision QPT-2339.dated October 8, 1974, authorizing the issue of a permit for transport by taxicab in behalf of the applicant, in the Municipality of Champlain.considering that said permit has already been authorized in behalf of Mr.Wellie Gervais, in this same Municipality.Rôle Q-2360 3034-A-P-l AUTOBUS ROI I.KM' ENRG.S4, 118e Avenue Drummondville (Que.) Rôle Q-2344 Q-200IS3-P-I LUCIEN ROY 5.du Moulin Lauzon Comté Levis (Que.) Rôle Q-2345 Q-200973-P-1 ALBERT GAGNON 457.Bagot Bagotville Comté Chicoutimi (Que.) Aux fins de réviser la décision QPV-348 pour la rendre conforme au règlement No 19 et à l'article 2.48.1 des règles de procédure, en remplaçant la durée du permis par la suivante: Ce service sera donné de septembre 1974 à juillet 1975.Aux fins de révoquer la décision QPT-1220, en date du 2 août 1974, autorisant la délivrance d'un permis de transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Lévis-Lauzon, A-35, vu le désistement du requérant.Aux fins de révoquer la décision QPT-1144, en date du 1 août 1974, autorisant la délivrance d'un permis de transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de la Baie.A-27, vu le désistement du requérant.For the purpose of revising decision QPV-348 to make it conformable to Regulation No.19 and and section 2.48.1 of the rules of procedure, by replacing the duration of the permit by the following: This service shall be provided from September.1974 to July, 1975.For the purpose of revoking decision QPT-1220.dated August 2.1974.authorizing the issue of a permit for transport by taxicab in the conglomeration of Lévis-Lau-zon, A-35.considering the applicant's withdrawal.For the purpose of revoking decision QPT-1144, dated August 1, 1974, authorizing the issue of a permit for transport by taxicab in the conglomeration of La Baie, A-27, considering the applicant's withdrawal.Rôle Q-2346 Q-201043-P-1 JÉRÔME DOUCET I.Hébert Baie-Comeau (Que.) Aux fins de révoquer les deux décisions, QPT-1088 et QPT-1091, autorisant la délivrance d'un permis de transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Baie-Comeau, A-21, vu le désistement du requérant.For the purpose of revoking the two decisions, QPT-1088 and QPT-1091, authorizing the issue of a permit for transport by taxicab in the conglomeration of Baie-Comeau, A-21, considering the applicant's withdrawal.Rôle Q-2363 13408-V-P-l AIR LINES TAXIS & BUSSES REG'D (Mme Yvonne Doré-Breton faisant affaires sous le nom de operating under the name of) : Québec 3 (Que., Aux fins de réviser le paragraphe 3 du dispositif de la décision numéro QS-647-S qui se lit comme suit: La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'à l'autorisation finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent, pour le remplacer par le suivant: La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'au 1er septembre 1975 ou jusqu'à disposition finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent, suivant l'éventualité qui se présentera la première.For the purpose of revising paragraph 3 of the enacting terms of decision QS-647-S, which read as follows: This authorization of transfer shall be temporary and valid until a final authorization is granted further to the request for authorization of transfer filed by the applicants, according to the procedure prescribed for regular and permanent permits, to replace it by the following: This authorization of transfer shall be temporary and valid until September 1, 1975 or until final disposal of the request for authorization of transfer filed by the applicants, according to the procedure prescribed for regular and permanent permits, whichever occurs first.Rôle M-3629 M-501072 MV-2301-P-002 MORIN, ROCER 218, rue du Marché Valleyfield Comté Beauharnois ,Qué.| Aux fins de réviser la décision MCV-2401 du 16 juillet 1974 de la cause MV-2301 dans laquelle le numéro de dossier sur la décision aurait dû se lire: M-501072.For the purpose of revising decision MCV-2401 dated July 16, 1974, regarding case MV-2301, wherein the file number appearing in the decision should have read: M-501072. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Ui novembre 1974.100' année, n° 4?> S663 Rôle M-3630 19350-V-P-2 murdock, léo 1013, boni.Vinet Beloeil, Comté Verchcres (Que.) mise en cause Aux fins de corriger la décision MCS-711 du 12 septembre 1974 de façon à ce qu'il soit bien indiqué que l'annulation du permis de remorquage de Léo Murdock No 19350-V concerne seulement le service autorise pour le compte de Matane Gaspésie Transport Inc.No 15267-V, vu que ce tireur est égale-ment autorisé à donner un service de remorquage pour le compte de Transport Amédée Cayer Inc.No 7401-V.qui est toujours en vigueur.For the purpose of correcting decision MCS-711 dated September 12.1974.so that it may be clearly indicated that the cancellation of the haulaway permit held by Léo Murdock (No.19350-V) concerns only the service authorized on behalf of Matane Gaspésie Transport Inc., No.15267-V.considering that this haulaway operator is also authorized to provide a haulaway service on behalf of Transport Amédée Cayer Inc.(No.7401-V), which is still in force.Kôle M-3738 19.000-V-lM courtemanche transport inc.700.chemin Authier St-Hilaire, Comté Houville (Que.) et 23,588-V p.d.transport enrg.(Dame Pauline Duhois-Baillargeon opérant sous le nom de / Operating under the name of :> 5245.rue Gamier Montréal (Que.) Rôle M-3770 M-206029-P-1 Cause No MT-7493 michaud, gilles 12365.rue Matte, app.3 Montréal-Nord (Que.; Aux fins de corriger, comme suit, la décision de la Commission MCR-1224 du 1er octobre 1974.Rôle M-2226.1, En indiquant au dispositif No 2 de la page 2 que la Commission autorise le transfert des clauses a, b, c du permis de la requé-rante-venderesse, permis No 19,000-V en faveur de la requérante-acquéreur, permis No 23.588-V.2.En indiquant que la requérante-vende-resse continuera à opérer les clauses rési-duaires rf.c./, g et h de son permis sous le No 19.000-V.cette dernière clause h ayant été omise lors de la décision précitée et qui se lit comme suit: Classe : h) Transport restreint - longue distance -rayon - contrat - Service: h) Des Chemins des Passes (millage 47) et Aima à tous les endroits de la province de Québec, pour le transport de bois, pour le compte de Emilien L.Morin Ltée.(Copies des permis Nos 19.000-V et 23.588-V ci-annexées ainsi que la décision MCR-1224.) Aux fins de réviser ou de révoquer pour cause, s'il y a Heu, la décision rendue le 2 octobre 1974 sous le numéro MPT-7993 autorisant la délivrance d'un permis de transport par véhicule-taxi de catégorie « Agglomération » et de catégorie « Ordinaire » pour l'agglomération A-5, Est de Montréal.S'il y a opposition ou intervention ou demande dans les dix jours de la publication de cet avis, l'audience publique à être tenue en conséquence aura lieu à Montréal, le lundi 18 novembre 1974.en la division No 2, à 10 h du matin.For the purpose of correcting as follows decision MCR-1224 rendered by the Commission on October 1.1974, Roll M-2226: 1.By indicating, in enacting term No.2 on page 2.that the Commission authorizes the transfer of clauses a.b, c of permit 19.000-V held by the applicant-vendor, in behalf of the applicant-purchaser, permit No.23.588-V.2.By indicating that the applicant-vendor shall continue to operate the remaining clauses d, e./, g and h of its permit under No.19.000-V; last-mentioned clause h, which was omitted at the time of the afore-mentioned decision, reads as follows: Class: (h) Restricted trucking - long distance -radius - contract - Service: (h) From the Chemin des Passes (mileage 47) and Alma to any point located in the Province of Quebec, for the transport of lumber, on behalf of Emilien L.Morin Ltce.(Copies of permits Nos.19,000-V and 23,588 and of decision MCR-1224 attached hereto.) For the purpose of revising or revoking for just cause, if need be.decision MPT-7993 rendered on October 2, 1974, authorizing the issue of a permit for transport by taxi-cab, \"Conglomeration\" category, and \"Ordinary\" category for conglomeration A-5, East of Montreal.Id any objection intervention or request is filed within ten days following the publication of this notice, the public hearing to be held in consequence thereof shall take place in Montreal, on Monday, November IS, 1974, in division No.2, at 10 o'clock a.m.Rôle Q-2414 13408-V-P-2 air lines taxis & busses reg'd.(Mme Yvonne Doré-Breton faisant affaires sous le nom de operating under the name of 167-169, rue Godbout Est Québec 3 (Qué.^ Aux fins de réviser le paragraphe 3 du dispositif de la décision numéro QS-646 qui se lit comme suit: La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'à l'autorisation finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent.pour le remplacer par le suivant: La présente autorisation de transfert est temporaire et valide jusqu'au 1er septembre 1975 ou jusqu'à disposition finale sur la demande d'autorisation de transfert introduite par les requérantes suivant la procédure prévue pour un permis régulier et permanent, suivant l'éventualité qui se présentera la première.For the purpose of revising paragraph 3 of the enacting terms of decision number QS-646.which reads as follows: This transfer authorization is temporary and shall be valid until a final authorization is granted further to the request for authorization submitted by the applicants according to the procedure prescribed for the obtain-ment of a regular and permanent permit.to replace by the following: This authorization of transfer is temporary and shall he valid until September 1.1975 or pending final disposition of the request for authorization submitted by the applicants according to the procedure prescribed for the obtainment of a regular and permanent permit, whichever occurs first.59032-O 8664 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.II \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.'Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle Q-2019 Q-502201 D-001 ST-LAURENT, LÉO (Mme Léo St-Laurent.légataire universelle universal legatee) 206.rue Fournier Matane Comté Matane (Que.) et Q-504324 D-001 ST-LAURENT, MARCEL 146, Riverin Matane Comté Matane (Que.) Demande de transfert: Le requérant-cédant, St-Laurent, Léo (Mme Léo St-Laurent, légataire universelle) demande à la Commission de transférer par vente au requérant-cessionnaire: Marcel St-Laurent 146, Riverin Matane Comté Matane (Que.) le permis ou l'attestation Q-502201 D-001 pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 1, catégorie Entrepreneur.N.B.\u2014 Nouvelle publication remplaçant celle du 12 octobre 1974 qui était erronée.Application for transfer: St-Laurent.Léo (Mrs, Léo St-Laurent, universal legatee) requests the Commission to transfer to the applicant-transferee Marcel St-Laurent 146 Riverin Matane County of Matane, P.Q.permit or certificate No.Q-502201 D-001 to effect bulk trucking in Region No.1, Artisan class.Note: New publication replacing the one dated October 12.1974, which was wrong.Rôle Q-2171 Q-202069 CAMILLE BRASSARD 555.rue de L'Eglise, app.10 Québec 2, (Que.) Le requérant demande à la Commission des transports du Québec un permis de propriétaire, pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Québec, A-36.The applicant requests from the Québec Transport Commission an owner's permit, to effect transport by taxicab in the conglomeration of Québec, A-36.Rôle Q-2314 Q-500950 D-001 CAMILLIEN CHARETTE CP.24 St-Vianney Comté Matapédia (Que.) Le requérant qui possède une attestation Q-500950 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500950 D-001.requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.1.Rôle Q-2315 Q-500950 D-002 CAMILLIEN CHARETTE CP.24 St-Vianney Comté Matapédia (Que.) Le requérant qui possède une attestation Q-500950 D-002 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500950 D-002, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.1.Rôle Q-2316 Q-500955 D-001 LABRIE, LUCIEN St-René Comté Matane (Que.) Le requérant qui possède une attestation Q-500955 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500955 D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.1.Rôle Q-2317 Q-502517-D-001 MAHEUX, ALBERT (Marguerite Mahcux, légataire universelle universal legatee) 134.Bertrand Ste-Thérèse-de-Lisieux (Que.) et Q-504671-D-001 ALAIN BRIND'AMOUR 136-A, Bertrand Ste-Thérèse-de-Lisieux (Que.) Demande de transfert: Maheux, Albert (Marguerite Maheux, légataire universelle) demande à la Commission de transférer au requérant cession-naire: M.Alain Brind'Amour 136-A, Bertrand Ste-Thérèse-de-Lisieux (Que.) le permis ou l'attestation Q-502517-D-001 pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 3, catégorie Artisan, Application for transfer: Maheux, Albert (Marguerite Maheux, universal legatee) requests the Commission to transfer to the applicant-transferee Mr.Alain Brind'Amour 130-A Bertrand Ste-Thérèse-de-Lisieux, P.Q.permit or certificate No.Q-502517-D-001 to offect bulk truckingin region No3, Artisan class. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 197A.106' année.n° A6 8665 Rôle Q-2318 Q-504096 TRANSPORT LÉVESQUE & OUELLET ENR.55, Aubin Mont-Joli (Que.) et 0-604308 LES ENTREPRISES YVON LÉVESQUE INC.1550, Aubin Mont-Joli (Que.) Rôle Q-2319 Q-200485 BOURASSA, ARMAND 808, Se Avenue Québec 3.(Que.) Q-202097 AUDET, CAROL 215, Des Lilas Ouest, app.6 Québec 3 (Que.) Rôle Q-2320 Q-503517-D-O06 ST-PIERRE, FÉLICIEN 391.Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Que.) et.Q-503317-D-004 DANIEL ST-PIERRE 625, Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Que.) Rôle Q-2321 LEBEL, MAURICE (Carmen Lebel, légataire universelle universal legatee) 69, St-Louis Rivière-du-Loup (Que.) et Q-504676-D-O01 MME CARMEN LEBEL 69, St-Louis Rivière-du-Loup (Que.) Rôle Q-2322 Q-501591-D-001 GIRARD, GERMAIN 1979, boul.Sacré-Coeur Dolbeau (Que.) et Q-504 654-D-001 MARTIAL PARENT 147, Boivin Mistassini (Que.) Rôle Q-2323 Q-200151 FILION, HÉLÈNE ROLAND 396, 2e Rue Québec 3 (Que.) Q-201336 D-2 ROBERGE, GILLES 218, Carré Dallaire, app.7 Neufchâtel (Que.) Demande de transfert : Transport Lévesque & Ouellet Enr.demande à la Commission de transférer à: Les Entreprises Yvon Lévesque Inc.1550, Aubin Mont-Joli Comté Matane (Que.) le permis ou l'attestation No Q-504096 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 1, pour la catégorie Entrepreneur.Application for transfer: Transport Lévesque & Ouellet Enr.requests the Commission to transfer to: Les Entreprises Yvon Lévesque Inc.1550 Aubin Mont-Joli County of Matane, P.Q.permit or certificate No.Q-504096 which he holds, to effect bulk trucking in Region No.1, Contractor class.Demande de transfert: Bourassa, Armand demande à la Commission de transférer à: Audet, Carol 215, Des Lilas Ouest, app.6 Québec 3 (Que.) le permis No Q-200485 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Québec, A-36.Application for transfer: Bourassa, Armand requests the Commission to transfer to: Audet, Carol 215 Des Lilas Ouest, Apt.6 Québec 3, P.Q.permit No Q-200485 to effect transport by taxicab in conglomeration A-36, Québec.Demande de transfert: St-Pierre, Félicien, demande à la Commission de transférer par donation à: Daniel St-Pierre 625, Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Que.) le permis ou l'attestation Q-503517-D-O06 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 4, catégorie Entrepreneur.Application for transfer: St-Pierre, Félicien, requests the Commission to transfer by donation to: Daniel St-Pierre 625 Notre-Dame Notre-Dame-du-Bon-Conseil, P.Q.permit or certificate No.Q-503517-D-O06 which he holds, to effect bulk trucking in region No.4, Contractor class.Demande de transfert: Le requérant cédant: Lebel, Maurice (Carmen Lebel, légataire universelle demande à la Commission de transférer au requérant cessionnaire : Mme Carmel Lebel 69, St-Louis Rivière-du-Loup (Que.) le permis ou l'attestation Q-501480-D-001 pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 3, catégorie Artisan.Application for transfer: The applicant-transferror: Lebel, Maurice (Carmen Lebel.universal legatee) requests the Commission to transfer to the applicant-transferee : Mrs.Carmen Lebel 69 St-Louis Rivière-du-Loup, P.Q.permit or certificate No.Q-501480-D-001 to effect bulk trucking in region No.3, Artisan class.Demande de transfert: Girard, Germain demande à la Commission de transférer à: Martial Parent 147, Boivin Mistassini Comté Lac St-Jean (Que.) le permis ou l'attestation Q-501591-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 2, catégorie Artisan.Demande de transfert: Filion, Hélène Roland demande à la Commission de transférer à: Roberge, Gilles 218, Carré Dallaire, app.7 Neufchâtel (Que.) le permis No Q-200151 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de Québec.A-36.Application for transfer: Girard, Germain requests the Comnrs-sion to transfer to : Martial Parent 147 Boivin Mistassini County of Lac St-Jean, P.Q.permit or certificate No.Q-501591-D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region 2, Artisan class.Application for transfer: Filion, Hélène Roland requests the Commission to transfer to: Roberge, Gilles 218 Carré Dallaire, Apt.7 Neufchâtel, P.Q.permit No.Q-200151 to effect transport by taxicab in conglomeration A-36, Québec. 8666 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.40 Rôle Q-2324 10533-V-D-l AUCLAIR TRANSPORT INC.1354.rue Notre-Dame Notre-Da me-des-Lo uren t ides (Que.) Rôle Q-2325 Q-500975 D-001 BENOIT PICHÊ 160.route 2 Cap-Santé Comté Portneuf (Que.) Modification de permis: La partie requérante, détentrice du permis suivant: Transport général - longue distance -route restreinte - De Notre-Dame-des-Laurentides, Tewkes-burv, Stoneham, Lac-Beauport.Charles-bourg.Lac-St-Charles, SNEmile.St-Adolphe :\\ Québec, et retour.Transport restreint - longue distance -ravon - irrégulier - De Notre-Dame-des-Laurentides a ailleurs dans la province, et retour, pour déménagements.Demande l'autorisation de modifier son permis pour qu'il se lise à l'avenir comme suit: Marchandises diverses: o-l) Transport général - service local - a-l) Notre-Dame-des-Laurentides et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville: a-2) Transport général - longue distance -rayon - a-2) De Notre-Dame-des-Laurentides à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite ville et retour.Transport de ménages et d'ameublements usagés dans des véhicules spécialement agencés et utilisés à cette fin selon l'article 51 de l'Ordonnance générale sur le camionnage.6-1) Transport restreint - longue distance - rayon \u2014 6-1) A Notre-Dame-des-Laurentides et de tout point à un autre dans un rayon de 50 milles des limites de ladite ville de Notre-Dame-des-Laurentides ; 6-2) Transport restreint - longue distance - rayon - 6-2) De Notre-Dame-des-Laurentides et de tous points situés dans un rayon de 50 milles des limites de ladite ville à tous points situés dans la Province et retour; 6-3) Transport restreint - longue distance - territoire - 6-3) De tout point à un autre dnns les limites de la Province, pourvu que la distance entre ces deux points soit de plus de 100 milles; 6-4) Transport restreint - longue distance - route restreinte - 6-4) De tous les points situés dans la province de Québec à la frontière Québec-Ontario et retour, (via tous les ports d'entrée) destination ou origine: les provinces du Canada à l'ouest de la province de Québec; 6-5) Transport restreint - longue distance - route restreinte - 6-5) De toutes les localités situées dans la province de Québec à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick et retour (tous les ports d'entrée) (Destination ou origine: les provinces du Canada à l'est de la province de Québec.Le requérant qui possède une attestation Q-500975 D-U01 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la Région No 3.Modification of permit: The applicant, which holds the following permit: General trucking - long distance - restricted route - .From Notre-Dame-des-Laurentides.Tew-kesburv.Stoneham, Lac Beauport, Charles-hourg/Lac-St-Charles, St-Emile, St-Adolphe to Québec City, and return.Restricted trucking - long distance - radius - irregular - From Notre-Dame-des-Laurentides to any point in the Province of Québec and return, for moves.Request sauthorization to modify said permit to read henceforth as follows: Miscellaneous goods: (a-l) General trucking - local service - (a-l) Notre-Dame-des-Laurentides and all points located within a distance of 5 miles from the limits of said Town; (a-2) General trucking - long distance -radius - (a-2) From Notre-Dame-des-Laurentides to all points located within a radius of 30 miles from the limits of said Town and return.Transport of household goods and used furniture by specially-equipped vehicles used exclusively to that purpose, pursuant to article 51 of the General Order on Trucking.(6-1) Restricted trucking - long distance -radius - (6-1) To Notre-Dame-des-Laurentides and from all points located within a radius of 50 miles from the limits of said Town of Notre-Dame-des-Laurentides ; (6-2) Restricted trucking - long distance -radius - (6-2) From Notre-Dame-des-Laurentides and from all points located within a radius of 50 miles from the limits of said Town to any point located in the Province of Québec, and return; (o-3) Restricted trucking - long distance -territory - (6-3) From any point to any other point located within the boundaries of the Province of Québec, provided that the distance between such two points exceeds 100 miles; (6-4) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-4) From any point located in the Province of Québec to the Québec-Ontario border (via all ports of entry); destination or origin: the Canadian Provinces west of the Province of Québec.(6-5) Restricted trucking - long distance -restricted route - (6-5) From any point located in the Province of Québec to the Québec-New-Brunswick border and return (all ports of entry).Destination or origin: the Canadian Provinces east of the Province of Québec.The applicant, who holds certificate Q-500975 D-001.requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.3. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° A6 8667 Rôle Q-2326 Q-500979 D\u2014001 LA SABLIÈRE DE WARWICK LTÊE R.R.4 Warwick Comté Arthabaska (Que.) Rôle Q-2327 Q-500978 D-001 BEGIN, BIZIER, CHABOT & LECOURS INC.Ste-Justine Comté Dorchester (Que.) Rôle Q-2328 Q-500974 D-001 M.JEAN-PAUL VAILLANCOU RT 400, boul.Dion Matane (Que.) Rôle Q-2329 Q-500972 D-001 M.LÉONARD DANCAUSE CP.814 Causapscal (Que.) Rôle Q-2330 Q-500969 D-001 M.DOMINIQUE CARON St-Damase Comté Matapédia (Que.) Rôle Q-2331 Q-500968 D-001 M.RENÉ MICHAUD St-Antonin Village Comté Rivière-du-Loup (Que.) Rôle Q-2332 Q-501918-D-001 LEFRANÇOIS, LÉONARD Pentecôte Comté Saguenay (Que.) et Q-504677-D-001 ADÉODAT BASTIEN CP.125, Ragueneau Comté Saguenay (Que.) Rôle Q-2333 1470-A GÉRARD TREMBLAY Les Eboulements Comté Charlevoix (Que.) 53-A AUTOBUS ALPHONSE DROLET LTÉE 2270.Notre-Dame Ste-Foy Québec 10 (Que.) 1470-A-D-l Le requérant qui possède une attestation Q-500979 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 4.The applicant, which holds certificate Q-500979 D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.4.Le requérant qui possède une attestation Q-500978 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 3.The applicant, who holds certificate Q-500978 D-001, requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.3.Le requérant qui possède une attestation Q-500974 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500974 D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class for region No.1.Le requérant qui possède une attestation Q-500972 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500972 D-001, requests a bulk trucking permit.Artisan class for region No.1.Le requérant qui possède une attestation Q-500969 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500969 D-001, request a bulk trucking permit, Contractor class for region No.1.Le requérant qui possède une attestation Q-500968 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 3.The applicant, who holds certificate Q-500968 D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.3.Demande de transfert: Lefrançois, Léonard demande à la Commission de transférer à: Adéodat Bastien CP.125.Ragueneau Cté Saguenay (Que.) le permis ou l'attestation Q-50191S-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 9.catégorie Artisan.Application for transfer: Lefrançois.Léonard requests the Commission to transfer to: Adéodat Bastien, P.O.Box 125, Ragueneau, County of Saguenay, P.Q.permit or certificate No.Q-501918-D-001 which he holds to effect bulk trucking in region No.9.Artisan class.Transfert de permis: Aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre à Autobus Alphonse Drolet Ltée, 2270, Notre-Dame.Ste-Foy, Québec 10 (Que.), les services de transport dûment autorisés en vertu du permis No 1470-A, comme suit à savoir: Classe de permis: Autobus.Service : De St-Joseph-de-la-Rive (Quai) à Québec et retour via les Eboulements.Parcours à suivre: Route régionale du Quai de St-Joseph-de-la-Rive aux Eboulements.Route 362 (ancienne route 15-A) des Eboulements à Baie-St-Paul.Route 138 (ancienne route 15) de Baie-St-Paul à Québec.De plus la requérante demande de suivre l'horaire suivant; Transfer of permit: For the purpose of obtaining authorization to sell to Autobus Alphonse Drolet.2270, Notre-Dame, Ste-Foy, Québec 10, P.Q.the transport service duly authorized according to permit No.1470-A, as follows, that is: Class of permit: Bus.Service : From St-Joseph-de-la-Rive (Quay) to Québec and return via les Eboulements.Route: Regional road from Quay of St-Joseph-de-la-Rive to the Eboulements.Highway 326 (former No 15-A) from the Eboulements to Baie-St-Paul.Highway 138 (former No.15) from Baie-St-Paul to Québec.Moreover, the applicant requests to follow the following time-table: 8668 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Rôle Q-2334 15130-V D-3 TF MODERN TANK LINES INC.520, bc-ul.St-Joseph, CP.515 Drummondville (Que.) Sur semaine / Week days: Départ de / Departure from: St-Joseph-de-la-Rive.$8.15 $ 13.15 Eboulements.8.25 13.25 Baie-St-Paul.8.45 13.45 Arrivée à Québec/ Arrival Québec.10.00 15.30 Départ de/ Departure from: Québec.9.00 16.30 Baie-St-Paul.10.30 18.00 Eboulements.10.50 18.15 St-Joseph, Quai.1100 18.30 Le dimanche/ On Sundays: Départ de' Departure from: St-Joseph-de-la-Rive.10.00 13.15 $ 18.15 Eboulements.10.10 13.25 18.25 Baie-St-Paul.10.30 13.45 18.45 Arrivée à Québec/ Arrivai Québec.12.45 15.30 20.30 .9.00 15.30 Baie-StrPaul.10.30 17.00 Eboulements.10.50 17.16 Quai.1100 17.30 La requérante demande à la Commission The applicant requests from the Transport des transports une augmentation de 8% de Commission an increase of 8% on its previous ses tarifs antérieurs d'huile et gazoline, du tariffs applicable to oil and gazoline, from pipe-line d'Impérial Oil Ltd.à Drum- the pipeline of Imperial Oil Ltd.to Drummondville, selon la clause c de son permis mondville, according to clause e of its permit No 15130-V.No.15130-V.Rôle Q-2335 19794-V-D-l MARCOUX, PAUL-ÊMILE St-Edouard-de-Frampton Comté Dorchester (Que.) G0R 1M0 Modification de permis (clause a): La partie requérante qui détient un permis dont la clause a se lit comme suit: a) Transport restreint - longue distance -route restreinte - a) De St-Edouard-de-Frampton et de tous les points situés dans un rayon de trente-cinq (35) milles dudit endroit, à l'exclusion de Ste-Hénédine et Ste-Claire-de-Dorchester, à Vallée-Jonction, Ste-;Marie-de-Beauce, Charny, St-Henri-de-Lévis, St-Ma-lachie et St-Charles-de-Bellechasse, pour le transport d'animaux vivants, pour le public en général.Désire que la clause a ci-dessus se lise à l'avenir comme suit: a) Transport restreint - longue distance -territoire - a) De tous points à tous points situés dans un rayon de cinquante (50) milles de St-Edouard-de-Frampton, pour le transport d'animaux vivants.Modification of permit (clause o): The applicant, who holds a permit in which clause a reads as follows: (a) Restricted trucking - long distance -restricted route - (a) From St-Edouard-de-Frampton and from any point located within a radius of thirty-five (35) miles from said point, with the exception of Ste-Hénédine and Ste-Claire-de-Dorchester, to Vallée-Jonction, Ste-Marie-de-Beauce, Charny, St-Henri-de-Lévis, St-Malachie and St-Charles-de-Bellechasse, for the transport of livestock, for the public at large.Wishes clause a hereinabove mentioned to to read henceforth as follows: (a) Restricted trucking - long distance -territory - (a) From any point to any other point located within a radius of fifty miles (50) from St-Edouard-de-Frampton, for the transport of livestock.Rôle Q-2336 24016-V-D-l GAGNON, MARC 680, 2ième Rue CP.632 Fermont (Saguenay) (Que.) Rôle Q-2338 Q-502083-D-001 RICHARD ROBINSON Gros-Morne Comté Gaspé-Nord (Que.) Demande de permis: La partie requérante demande le permis suivant: Transport général - longue distance - territoire - Fermont et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas vingt (20) milles des limites dudit endroit, et retour.Transport restreint - longue distance -route restreinte - De Wabush et de Labrador City à Fer-mont et à Mont-Wright, et retour, pour le transport de courrier et de colis postaux.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Artisan, pour la région No 1.Application for permit: The applicant requests the following permit: General trucking - long distance - territory - Fermont and all points located within a distance of twenty (20) miles from the limits of said point, and return.Restricted trucking - long distance - restricted route - From Wabush and Labrador City to Fermont and Mont-Wright, and return, for the transport of mail and postal parcels.The applicant requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.1. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974.106' année.n° 46 8669 Rôle Q-2339 Q-502828-D-001 McKINLEY, HENRY 1666.boni.Valcartier Village Valcartier (Que.) et / and Q-504678-D-001 LÉONARD LOUGHREN 133, 5ième Concession Village Valcartier (Que.) Rôle Q-2340 Q-501068-D-001 PÊRIGNY, MARIO 700, Marchand St-Tite Comté St-Maurice (Que.) et / and Q-504679-D-001 ANDRÉ NOËL 942, Frigon Shawinigan (Que.) Rôle Q-2341 24032-V-D-l LES SERVICES SOUS-MARINS DE MINGAN INC./M1NGAN UNDERWATER SERVICE INC.289 Des Menuisiers Case postale 1 Sept-Iles (Que.) Rôle Q-2342 Q-500733 D-001 MARIO SAVARD 634.rue Albanel Chicoutimi (Que.) Rôle Q-2347 Q-500996 D-001 BERTHIER FILLION CP.1220, Bic Comté Rimouski (Que.) Rôle Q-2348 Q-500992 D-001 ARMAND GUILLEMETTE St-Lambert Comté Lévis (Que.) Rôle Q-2349 Q-500987 D-001 EDDY LABARRE R.R.No 1, St-Raymond Comté Portneuf (Que.) Rôle Q-2350 Q-504673 D-001 ROMÉO TÊTU Boul.Des Pompes St-Agapit Comté Lotbinière (Que.) Rôle Q-2351 Q-504616 D-001 ROGER TREMBLAY 706, rue St-Edouard St-Urbain Comté Charlevoix (Que.) Demande de transfert: McKinley.Henry, demande !i la Commission de ira nsférer à : Léonard Loughren 133, 5ième Concession Village Valcartier, Comté Chauveau (Que.) le permis ou l'attestation Q-502828-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 3, catégorie Artisan.Demande de transfert: Périgny.Mario demande à la Commission de transférer à: André Noël 942, Frigon Shawinigan, Comté Laviolette (Que.) le permis ou l'attestation Q-501068-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 4, catégorie Artisan.Demande de permis: La partie requérante demande le permis suivant: Transport restreint - longue distance -territoire - irrégulier - véhicule vacuum - De tout point à tout autre point de la province de Québec, pour le transport de rebuts pétroliers ou dérivés de ces produits, ou de produits chimiques, ou de tout autre produit, par véhicule-citerne spécialement muni d'une pompe et agencé à cette fin, rebuts ou produits devant être incinérés, enfouis dans le sol ou recyclés.Le requérant qui possède une attestation Q-500733 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 2.Le requérant qui possède une attestation Q-500996 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 1.Le requérant qui possède une attestation Q-500992 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 3.Le requérant qui possède une attestation Q-500987 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Artisan pour la région No 3.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, transport de bois de pulpe et toute autres matières en vrac, de catégorie Artisan pour la région No 3.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, transport de gravier, bois non-usiné, asphalte et toutes autres matières en vrac, de catégorie Entrepreneur pour la région No 3.Application for transfer: McKinley, Henry, requests the Commission to transfer to: Léonard Loughren 133 - 5th Concession Village Valcartier, County of Chauveau.P.Q.permit or certificate Q-502828-D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region No.3, Artisan class.Application for transfer: Périgny.Mario, requests the Commission to transfer to: André Noël 942 Frigon Shawinigan, County of Laviolette, P.Q.permit or certificate Q-501068-D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region No.4, Contractor class.Application for permit: The applicant requests the following permit: Restricted trucking - long distance - territory - irregular - vacuum vehicle - From any point to any other point in the Province of Québec, for the transport of petroleum waste, by-products thereof, chemicals or any other product, by tank vehicle specially equipped with a pump and designed for that purpose, said refuse and products to be incinerated, buried or reprocessed.The applicant, who holds certificate Q-500733 D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.2.The applicant, who holds certificate Q-500996 D-001, requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.1.The applicant, who holds certificate Q-500992 D-O01.requests a bulk trucking permit.Artisan class, for region No.3.The applicant, who holds certificate Q-500987 D-001.requests a bulk trucking permit, Artisan class, for region No.3.The applicant requests a bulk trucking permit, for the transport of wooo.pulp ana any other bulk product, Artisan class, for region No.3.The applicant requests a bulk trucking permit, for the transport of gravel, rough timber, asphalt and any other bulk product, Contractor class, for region No.3. 8670 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106.No.46 Rôle Q-2352 30002 D-l TF LES ENTREPRISES DE CAMIONNAGE DE QUÉBEC ET DE LA BANLIEUE 198.2ième Avenue Québec 3 (Que.) Les Entreprises de Camionnage de Québec et de la banlieue, ont déposé a la Commission des transports de nouveaux taux comportant différentes augmentations a l'ordonnance 5677-74, tarif No 9, augmentations de 10% environ, suivant les clauses de marchandises y décrites.Les intéressés peuvent consulter les nouveaux taux en s'adressant à la Commission des transports du Quéliec, 585.boul.Charest est.Québec (Que.) Les Entreprises de Camionnage de Québec et de la banlieue\" have filed with the Transport Commission their new rates comprising various increases on Order 5677-74.Tariff No.9, such increases amounting to approximately 10%, according to the clauses of goods described therein.Interested parties may consult the new rates filed with the Québec Transport Commission, 585 Charest Boulevard East, Québec City, P.Q.Rôle Q-2353 2077-A D-2 TF CYR, CONRAD Gascon Comté Bonaventure (Que.) Rôle Q-2354 Q-200949 LEPAGE, GÉRARD 209, de la Fabrique Jonquière (Que.) Q-202103 CÔTÉ.HERMAN 232, Châteauguay Jonquière (Que.) Rôle Q-2355 Q-504144-D-001 GUILLEMETTE, JEAN-GUY Berthier-sur-Mer Comté Montmagny (Que.) et / and Q-504680-D-001 GILLES BOULET Chemin 9, Cap-St-Ignace Comté Montmagny (Que.) Le requérant demande â la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs actuels, pour le transport des écoliers le midi de l'école St-Jean-Eudes, Chandler à Newport, aller et retour.Taux actuels: S0.50 aller et retour.Taux proposés: Î0.75 aller-retour.Demande de transfert: Lepage, Gérard demande à la Commission de transférer à: Côté, Herman 232, Châteauguay Jonquière (Que.) le permis No Q-200949 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans l'agglomération de l'ouest du Saguenay.A-51.Demande de trasnfert : Guillemette Jean-Guy demande à la Commission de transférer à : Gilles Boulet Chemin 9.Cap-St-Ignace Comté Montmagny (Que.) le permis ou l'attestation Q-5O4144-D-0O1 qu'iï détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 3.catégorie Artisan.The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase its present rates for the transport of pupils at noontime from St-Jean-Eudes School, Chandler to Newport, and return.Present rates: 80.50 round trip.Proposed rates: SO.75 round trip.Application for transfer: Lepage.Gérard requests the Commission to transfer to : Côté, Herman 232 Châteauguay Jonquière, P.Q.permit No.Q-202103 to effect transport by taxicab in conglomeration A-51, L'Ouest du Saguenay.Application for transfer: Guillemette Jean-Guy requests the Commission to transfer to: Gilles Boulet Chemin 9, Cap-St-Ignace County of Montmagny, P.Q.permit or certificate No.Q-504144-D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region No.3, Contractor class.Rôle Q-2356 24031-V-D-l TARDIF, GEORGES-EMILE St-Méthode-de-Frontenac tQué.) Rôle Q-2357 24033-V-D-l PITRE, CLAUDE 77, rue Duguay Cap-de-la-Madeleine (Que.) Rôle Q-2358 16903-V-D-7 CARTIER TRANSPORT INC.153, rue Maltais Sept-Iles (Que.) Nouvelle demande: La partie requérante demande a la Commission l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport restreint - longue distance -route restreinte - De St-Méthode-de-Frontenac aux abattoirs de Stoke, de Vallée-Jonction et à l'encan d'animaux de La Guadeloupe, pour le transport d'animaux vivants.Nouvelle demande: La partie requérante demande le permis suivant: Transport général - longue distance - territoire - Entre tous points situés dans un rayon de cent (100) milles de Cap-de-la-Madeleine.Modification de permis: La requérante désire être autorisée i donner le service de transport suivant: Transport général - longue distance -route restreinte - De Havre-St-Pierre à Sept-Iles et Port-Cartier et retour.New application: The applicant requests from the Commission authorization to provide the following transport service: Restricted trucking - long distance - restricted route - From Saint-Méthode-de-Frontenac to the slaughter-houses of Stoke, Vallée-Jonction and to the livestock auction market in La Guadeloupe, for the transport of livestock.New application : The applicant requests the following permit: General trucking - long distance - territory - Between all points located within a radius of one hundred (100) miles from Cap-de-la-Madeleine.Modification of permit: The applicant wishes to be authorized to provide the following transport service: General trucking - long distance - restricted route - From Havre-Saint-Pierre to Sept-Ues and Port-Cartier and return. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ir, notembre 1974.106' année.«\" 46 8671 Rôle Q-2359 3111-V-D-2 piuze transport inc.2222.Lavoisier Ste-Foy.Québec 10 (Qué.l Role Q-2361 Q-500004 D-1104 transbois inc.4.Parc Samuel Holland Suite 1701 Québec GIS 3R3 Rôle Q-2362 Q-500004 D-005 transbois inc.4, Parc Samuel Holland Suite 1701 Québec GIS 3R3 Rôle Q-2364 2248-V-D-2 dallaire, guy-noël 106.rue Dupont.C.P.105 St-Ludger Comté Frontenac (Que.) GOM 1W0 Rôle Q-2365 Q-503970-D-001 cimon laval 639.Lapointe Chicoutimi (Que.) et / and Q-504681-D-001 j.b.tremblay 644.Lapointe Chicoutimi (Que.) Rôle Q-2366 Q-500997 D-001 raynald dionne 38.Normand Sud Amqui Comté Matapédia (Que.) Rôle Q-2367 Q-500998 D-001 sept-îles car loading service inc C.P.186, 294 Noël Sept-Iles (Que.) Rôle Q-2368 21204-V-D-l ciroux.alexandre St-Gédéon Comté Frontenac (Que.) et/and roy, arlane St-Gédéon Comté Frontenac 'Que.) Modification de permis: La requérante désire être autorisée a donner le service de transport suivant: Transport général - longue distance -route restreinte - De Havre-St-Pierre A Sept-Iles et Port-Cartier et retour.La requérante demande un permis de camionnage en vrac (transport de copeaux de bois), de catégorie F.ntrepreneur, pour la région No 3.Modification of ]>ermit: The applicant wishes to be authorized to provide the following transport serviie: General trucking - long distance restricted route - From Havre-Saint-Pierre to Sept-Iles and Port-Cartier and return.The applicant requests a bulk trucking permit, (transport of wood chi|*), Contractor class, for region No.3.La requérante demande un permis de camionnage en vrac (transport de copeaux de bois), de catégorie Entrepreneur, pour la région No 3.The applicant requests a bulk trucking permit (transport of wood chips) Contractor class, for region No.3.Modification de permis: La partie requérante demande d'ajouter à son permis le service suivant : De St-Gédéon à la frontière Québec-Ontario (tous les ports d'entrée) à destination de tous les points situés en Ontario et retour, pour le transport d'acier pour le compte de Canam Steel Works Inc.Ce service ne sera opéré que conjointement avec un permis complémentaire de l'Ontario Highway Transport Hoard, dont copie devra être déposée au dossier.Demande de transfert: Cimon Laval demande a la Commission de transférer à: J.B.Tremblay 644.Lapointe Chicoutimi (Que.) le permis ou l'attestation Q-503970-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac dans la région No 2.catégorie Entrepreneur.Modification of permit: The applicant requests that the following service be added to his permit: From Saint-Gêdéon to the Québec-Ontario border (all ports of entry) to all points located in Ontario, and return, for the transport of steel on behalf of Canam Steel Works Inc.This service shall be operated only in conjunction with a complementary permit from the Ontario Highway Transport Board, a copy of which shall be filed in the records.Application for transfer: Cimon Laval requests the Commission to transfer to: 1.B.Tremblay 644 Lapointe Chicoutimi, P.Q.permit or certificate Q-503970-D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region No.2.Contractor class.Le requérant qui possède une attestation Q-500997 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 1.The applicant, who holds certificate Q-500997 D-001.requests a bulk trucking permit, Contractor class, for region No.1.Le requérant qui possède une attestation Q-500998 D-001 demande un permis de camionnage en vrac, catégorie Entrepreneur pour la région No 9.The applicant, which holds certificate Q-500998 D-001.requests a bulk trucking permit.Contractor class for region No.9.Demande de transfert: M.Alexandre Giroux demande que son permis de transport soit transféré à M.Ariane Roy.Le permis de transport No 21204-V: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - De St-Gédéon à La Guadeloupe, pour le transport d'animaux vivants, pour le compte de Veilleux & Frères, de La Guadeloupe.Request for transfer: Mr.Alexandre Giroux requests that his transport permit be transferred to Mr.Ariane Roy.The transport permit No.21204-V: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract- From St-Gédéon to La Guadeloupe, for the transport of live animals, on behalf of Veilleux & Frères, of La Guadeloupe. 8672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16, 1974, Vol.106.No.46 Rôle M-3625 14113-V-D-l canada transport limited 378 Coleman Street Belleville, Ontario Au Québec / In Québec 1030, Chcrrier, suite 207 Montréal (Que.) Rôle M-3631 5599-V-D-l tremblay transport enrc.(M.Gaétan Bélisle opérant sous-le-nom de / operating under the name of:) L'Annonciation, comté Labelle (Que.) Rôle M-3632 17431-V-D-2 lafferty-smith express lines ltd.P.O.Box 696 Belleville, Ontario Au Québec / In Québec 1030.Cherrier, suite 207 Montréal 132 (Que.) Droit additionnel: La requérante, qui détient actuellement un permis qui se lit comme suit: Transport restreint - longue distance -route restreinte - De la frontière Québec - Ontario (point d'entrée: Rivière-Beaudette) ft Montréal, et retour, pour le transport de produits en conserve ou en bouteille, de fromage, oe matières utilisées dans la fabrication du fromage, de riz, de sucre et de produits provenant des fermes, des laiteries et des crémeries.Condition: Ce permis ne sera exploité qu'avec l'attestation délivrée par ['Ontario Highway Transport Board le 12 décembre 1956.demande respectueusement à la Commission des transports du Québec d'ajouter à son permis le droit additionnel suivant: Droit additionnel: En donnant les services décrits dans son permis, la détentrice a été autorisée à utiliser des véhicules isothermes.Condition : Si le droit additionnel est accordé, la requérante devra déposer à la Commission une attestation complémentaire délivrée par YOntario Highway Transport Board.Nouvelle clause: La requérante demande respectueusement à la Commission des transports du Québec l'autorisation de donner le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat -Service: De Ste-Véronique et L'Annonciation à.la frontière Québec - Ontario (Ports d'entrée: Rivière-Beaudette et Pointe-Fortune), à destination de Toronto Métropolitain, pour le transport de meubles neufs emballés et non-emballés.pour le compte de L'Annonciation Furniture Ltée et Norbec Furniture Inc.Description de la demande: La requérante, qui détient présentement un permis dont la clause b se lit comme suit: b) Transport restreint - longue distance -rayon - route restreinte - contrat - 6) De la frontière Québec-Ontario (points d'entrée: Hull, Pointe-Fortune, Rivière-Beaudette) à destination de toutes les localités situées dans un rayon de 200 milles du point d'entrée utilisé lors de ce service, pour le transport de bois de charpente, de poteaux, de blocs, oe madriers, de montants et de traverses, pour le compte de/et sur paiement des frais de transport par Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division, et au retour, pour le transport de matériaux du même genre, à partir de Montréal, lesdits matériaux provenant de Delson (Québec), pour le compte de/et sur paiement des frais de transport par Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division.(En vertu de cette clause, le transbordement est permis à Montréal).L'origine de la marchandise transportée à partir de l'Ontario sera l'usine de Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division, située à Trenton (Ontario), et la destination ces matériaux transportés au retour sera aussi ladite usine située à Trenton (Ontario).Additional right: , , The applicant which now holds a permit described as follows: Restricted trucking - long distance - restricted route - , i / From the Québec-Ontario border (port of entry: Rivière-Beaudette) to Montreal and return for the transportation of canned or bottled goods, cheese, materials, used in the manufacture of cheese, rice, sugar and products of farms, dairies and creameries.Condition: This permit is to be operated solely in conjunction with the certificate issued by the Ontario Highway Transport Board on December 12th, 1956.respectfully submits to the Québec Transport Commission an application to add to its permit the following additional right: Additional right: , , - .When giving the services described in its permit, the license is authorized to use temperature-controlled véhicules.Condition; If the additional right is granted the applicant shall file with the Commission a complementary certificate issued by the Ontario Highway Transport Board.New clause: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - contract -Service: From Ste-Véronique and L'Annonciation to the Québec-Ontario border (Ports of entry: Rivière-Beaudette and Pointe-Fortune) to the Metropolitan Toronto, for the transport of crated and non-crated new furniture, on behalf of L'Annonciation Furniture Ltée and Norbec Furniture Inc.Description of the application: The applicant which now holds a permit of which clause b is described as follows: (6) Restricted trucking - long distance -radius - restricted route - contract - (q) From the Québec-Ontario border (ports of entry: Hull, Pointe-Fortune, Rivière-Beaudette) to all localities situated within 200 miles from the port of entry used in giving the service, for the transportation of poles, lumber, blocks, timbers, posts and ties, for the account of/and against payment of the transportation charges by Domtar Chemicals Limited.Wood Preserving Division, and on the return trip for the transportation from Montreal of similar materials, originating at Delson, Québec, for the account of/and against payment of the transportation charges by Domtar Chemicals Limited.Wood Preserving Division (Transhipment under this clause is permitted at Montreal).The origin of the merchandise transported from Ontario shall be the plant of the Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division, at Trenton, and the destination of material transported on the return trip shall likewise be the said plant at Trenton.Ontario. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971.106' année, n° 16 8673 Rôle M-3634 3289-a-d-2 savard, jacques 11,562, rue Rolland Montréal-Nord (Que.) Rôle M-3636 M-503293-D-001 beaulieu, emile 481, rue Mattawin St-Michel-des-Saints Comté Berthier (Que.) bellerose, marcel 7781, chemin Brossard St-Michel-des-Saints Comté Berthier (Que.) Rôle M-3637 1367-DY 1190-DYV D-l location de véhicules pie ix enrc.8260, boul.Pie IX Montréal (Que.) demande respectueusement à la Commission des transports du Québec de remplacer ladite clause 6 par la suivante: b) Transport, restreint - longue distance -route restreinte - contrat \u2014 b) De la frontière Québec-Ontario (tous points d'entrée) à tous les points de la province de Québec, et retour, pour le transport de produits pour/et pour le compte de Domtar Chemicals Limited.Wood Preserving Division.L'origine de la marchandise transportée à partir de l'Ontario sera l'usine de Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division, située à Trenton (Ontario), et la destination des matériaux transportés au retour sera aussi ladite usine située à Trenton (Ontario).La requérante demande aussi un permis additionnel suivant: g) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - g) De la frontière Québec-Ontario (tous points d'entrée), en transit à travers la province de Québec, à la frontière Québec-Etats-Unis (tous points de sortie) pour acheminement ultérieur vers certains endroits aux Etats-Unis, et retour, pour le transport de produit pour/et pour le compte de Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division.(Rapport annexé).Le requérant s'est adressé à la Commission des transports du Québec afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service : Transport d'enfants de trois (3) à sept (7) ans, de leur résidence située Qans les municipalité de Côte-des-Neiges, Snowdon, Outremont.Ville St-Laurent et Ville Mont-Royal et se rendant à « l'Ecole Town of Mount-Royal Nursery School située rue Churchill, Ville Mont-Royal, Que.et retour.» Ce service sera donné de septembre 1974 à juin 1975.Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à : Bellerose, Marcel 7781, chemin Brossard St-Michel-des-Saints Comté Berthier (Que.) l'attestation No M-503293, D-001, qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 6, catégorie Artisan.Nouvelle demande: La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation de donner les services de location suivants: Service 1 : Location à court terme (moins d'un an) de véhicules de plaisance pour le public en général au 8260, boul.Pie IX, k Montréal (Que.).Service 2: Location à long terme (plus d'une année) de véhicules de plaisance pour le public en général.Service 3 : Location à court terme (moins d'un an) de véhicules de commerce et de livraison (ca- respectfully submits to the Québec Transport Commission an application to replace the said clause 6 by the following: (6) Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - (6) From the Québec-Ontario border (all ports of entry) to all points in the Province of Québec, and return for the transportation of products for/and on behalf of Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division.The origin of the merchandise transported from Ontario shall be the plant of the Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division, at Trenton, and the destination of material transported on the return trip shall likewise be the said plant at Trenton, Ontario.The applicant also applies for an additional permit described as follows: (g) Restricted trucking - long distance-restricted route - contract - (ft) From the Québec-Ontario border (all ports of entry), in transit through the Province of Québec, to the Quebec-United States border (all ports of exit) for furtherance to points in the United States and return, for the transportation of products for and on behalf of Domtar Chemicals Limited, Wood Preserving Division.(Reports annexed) The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: Class of permit : Bus service.Service : Transport of children aged three (3) to seven (7) years, from their homes located in the Municipalities of Côte-des-Neiges ,Snow-don, Outremont, City of Saint-Laurent and Town of Mount Royal, to the Town of Mount Royal Nursery School, located on Churchill Street in the Town of Mount Royal, P.Q., which they attend, and return.This service shall be provided from September, 1974 to June, 1975.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Bellerose.Marcel 77S1 Brossard Road St-Michel-des-Saints County of Berthier, P.Q.certificate No.M-503293, D-001, which he holds, to effect bulk trucking in region 6, Artisan class.New application: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following leasing services: Service 1 : Short-term leasing (less than one year) of pleasure vehicles for the general public at 8260 Pie IX Blvd., in Montreal.P.Q.Service 2: Long-term leasing (more than one year) of pleasure vehicles for the general public.Service 3: Short-term leasing (less than one year) of commercial and delivery vehicles (trucks, s674 QUÉBEC OE E ICI Al.GAZETTE.November 16.1974.Vol.106.No.46 Role M-3638 159-DYV 697-DY D-l jacques hinse ltée 114.nie du Roi Asbestos (Qué.l Rôle M-3G40 M -500044-D-001 geoffroy, albert 101, chemin St-C.abriel St-Félix-de-Valois (Que.) M-505929-D-001 loi selle, andré 760, Rivière-Bayonne Berthierville Comté Berthier (Que.) mions, tracteurs, remorques) pour le public »n général au 8260.boul.Pie IX.à Montréal (Que.).Service 4: Location à.long terme (plus d une année) de véhicules de commerce et de livraison (camions, tracteurs, remorques) pour le public en général.Transfert de permis: La requérante-venderesse s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but de l'autoriser à transférer ses permis 159-DYV-697-DY ù: Location A.D.VV.Inc.Demande de transfert: Le requérant-cédant demande h la Commission de transférer a : Loiselle.André 760, Rivière-Bayonne Berthierville Comté Berthier (Que.) l'attestation No M-500044.D-001 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 6, catégorie Artisan.tractors and trailers) for the gênerai public at 8260 Pie IX Blvd.in Montreal.P.Q.Service 4: Long-term leasing (more than one year) of commercial and delivery vehicles (trucks, tractors and trailers) for the general public.Transfer of permit: The applicant-vendor requests from the Québec Transport Commission authorization to transfer its permits 159-DYV -697-DY to: Location A.D.W.Inc.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Loiselle, Abdré 760 Rivière-Bayonne Berthierville Countv of Berthier.P.Q.certificate No.500044.D-001.which he holds, to effect bulk trucking in region 6.Artisan cl-, s.Rôle M-3641 1I470-V-D-2 active cartage limited 1065 Martin Grove Road Rexdale.Ontario Au Québec ' In Québec 4848, rue Dunn Montréal (Que.) Rôle M-3642 15140-V-D-2 delson transport limitée C.P.250, Delson Comté Lapraitie (Que.) Nouvelle clause: La requérante désire ajouter le service suivant : Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service: De la frontière Québec-Ontario (tous points d'entrée), en transit h travers la province de Québec, il la Irontière Québec-Nouveau-Brunswick (tons points d'entrée^ ; destination: toute localité située dans les provinces .suivantes: Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Kcosse.Ile du Prince-Edouard, Terre-Neuve, et retour, pour le transport d'acier en provenance ou h destination de toute localité située aux Etats-Unis ou en Ontario, et aussi de tuyaux et de poteaux de béton ou de métal précontraint en provenance de l'Ontario, pour le grand public.Nouvelles clauses: La partie requérante s'adresse h la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir le droit de donner les services de transport suivants: 1.Transport restreint - longue distance-rayon - 1.De Delson à tous les endroits situés dans un rayon de 500 milles de ladite municipalité, pour le transport de blocs, dalles en béton léger cellulaire, accessoires, machineries et autres produits de BASF Canada Ltd.et retour, avec marchandises refusées ou endommagées.2.Transport restreint - longue distance -route restreinte - 2.De Delson a la frontière Québec-Ontario (ports d'entrée: Rivière-Beaudette, Pointe-Fortune et Hull) pour le transport des produits de BASF Canada Ltd.de Delson.et retour avec marchand ises refusées.(Point de destination en Ontario: territoire borné au nord par la rivière Ottawa, à l'est par la province de Ouébec.au sud par le fleuve M-Laurent et 9 l'ouest par la route 41 allant de Napanee à Pembroke.New clause: Applicant wishes to add the following service: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route -Service: From the Québec-Ontario border (all ports of entry), in transit through the Province of Québec, to the Québec-New Brunswick, border (all ports of entry): destination: all points of the Province of New Brunswick Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland, and return, for the transportation of steel originating from or destined to all points of the United States and the Province of Ontario, of pipe, poles, of pre-stressed concrete and/or metal originating from all points of Ontario, for the public in general.New clauses: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport services: 1.Restricted trucking - long distance -radius - 1.From Delson to any point located within a radius of 500 miles from the limits of said Municipality, for the transport of light gas concrete blocks and slabs, machiner and other products of BASF Canada Ltd., and return with refused or damaged goods.2.Restricted trucking - long distance -restricted route - 2.From Delson to the Québec-Ontario border (ports of entry\".Rivière-Beaudette, Pointe-Fortune and Hull) for the transport of products of BASF Canada Ltd.from Delson, and return with refused goods.(Destination in Ontario: the territory bounded to the north by the Ottawa River, to enst by the Province of Québec, to the south by the St.Lawrence River, and to the west by Highway 41, (Napanee-Pembroke). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 S675 Rôle M-501536-D-006 bélanger & fils inc.C.P.6 Rouyn Comté Témiscamingue (Que.) M-5051)28-D-001 morissette, andré 7 McDonald Noranda Comté Rouyn-Noranda (Que.) Rôle M-3644 llll-V-D-1 TF olympique transport enrc.1667, Place Beaurhesne Montréal (Que.) Rôle M-3645 1417-V-D-l tf trans ile inc.1500 Bellevue Blvd.S.Greenfield Park (Que.) Rôle M-3646 12353-V-D-2 TF e.t.tank lines ltd.820, rue George Sherbrooke (Que.) Rôle M-3670 M-5051S5-D-OO1 lafond, denis 11 Ivray Terrasse Bédard Lanoraie Comté Berthier (Que.) M-505901-D-C01 lafond, pierre 170.rue Houle St-Paul Comté Joliette (Que.) Rôle M-3671 2020-A-D-6 transport chartrand inc.95.boul.Industriel Longueuil (Que.) Rôle M-3673 24022-V-D-l johnson, deane Cornwall, R.R.4 Prince Edw.Island Voituricr-remorqueur brad's transport limited P.O.Box 3 Charlottetown.P.E.I.Voiturier-roulier Demande de transfert: Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer à: Morissette.André 7 McDonald Noranda Comté Rouvn-Noranda (Que.) l'attcsta'ion No M-501536, D-006 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 8, catégorie Entrepreneur.Demande de fixation d'un taux de $45 le voyage de Montréal ù Ste-Thérèse et retour avec camion-boîte 18'.exclusivement pour les cheniins defer, conformément à la clause 6 de son permis.Augmentation des taux horaires de S3 à A4 par heure, et augmentation des taux des commodités de 5% à 10% par cent (100) livres.La requérante demande à la Commission une augmentation de 8% de ses tarifs antérieurs d'huile et gazoline.des bouches du pipeline de Drummondville.selon les clauses e,I.g de son permis No 12353-V.Demande de transfert : Le requérant-cédant demande à la Commission de transférer a: Lafond.Pierre 170.rue Houle St-Paul Comté Joliette (Que.) l'attestation No M-505185.D-001 qu'il détient pour effectuer du camionnage en vrac dans la région 10, catégorie Artisan.La requérante demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe de permis: Service d'autobus.Service: Transport d'étudiants du Champlain Regional College entre les deux (2) Campus du Collège, l'un situé au 900 Riverside Drive, St-Lambert et l'autre au 901 Tiffin Road, Longueuil, et retour.Ce service sera donné pour la période scolaire de 1974 à 1975.Horaire: Ce service sera donné entre 8.00 hres A.M.et G.00 hres P.M.Le voiturier-remorqueur demande à la Commission des transports du Québec, le droit de donner, aux conditions réglementaires, le service de transport suivant : Classe: Transport restreint - remorquage seulement -Service: Transport par remorquage, pour tirer les remorques vides ou chargées du requérant-conjoint: Brad's Transport Limited (20136-V), qui agira comme voiturier-roulier.Ce service sera effectué en vertu de toutes les clauses du permis du roulier, ledit permis portantle numéro 20136-V.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Morissette.André 7 McDonald Noranda County of Rouvn-Noranda.P.Q.certificate No.M-501536.D-006, which he holds, to effect bulk trucking in region 8, Contractor class.Application for the fixation of a rate of $45 per trip, from Montreal to Ste-Thérèse.and return, with an 18-foot box truck, railway companies exclusively, according to clause 6 of its permit.Hourly rates increased from $3 to $4 per hour, and 5% to 10% increase on hundred (100) pounds rates applicable to commodities.The applicant requests from the Commission an increase of 8% in its former oil and gasoline tariffs, from the Drummondville pipeline, pursuant to clauses r, /, g of its permit No.12353-V.Application for transfer: The applicant-transferror requests the Commission to transfer to: Lafond.Pierre 170 Houle Street St-Paul County of Joliette.P.Q.certificate No.M-505185.D-001 which he holds, to effect bulk trucking in region 10.Artisan class.The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following service: Class of permit: Bus service.Service : Transport of students from the Champlain Regional College between the College's two (2) campuses, the one located at 900 Riverside Driver.St-L3mbert.and the other at 901 Tiffin Road.Longueuil.and return.This service shall be provided during the 1974-75 school year.Schedule: This service shall be provided between 8:00 o'clock a.m.and 6:00 o'clock p.m.The haulaway operator requests from the Quebec Transport Commission authorization to provide the following transport service, under the prescribed conditions: Class: Restricted trucking - haulaway only -Service : Haulaway transport, to haul the (empty or loaded) trailers belonging to the joint applicant: Brad's Transport Limited (20136-V), which shall act as carrier.This service shall be effected pursuant to all clauses of carrier's permit No.20136-V. S676 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol 106, No.40 Rôle M-3G74 24029-V-D-l BRUNSWICK PETROLEUM TRANSPORT LTD.Ashburn Lake Road.Group Box 19, Saint-John, N.B.Au Québec / In Québec 7887, rue Grenache Ville d'Anjou ) - ni -!.< Mecislovas 8048, rue Querhes Montréal (Que.) le permis No M-203617 D 5 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll.Montréal.Demande de transfert : Gagné, Arthur demande a la Commission de transférer k: Mercier, Gilles 3137, rue Parkville Montréal (Que.) le permis No M-204385 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert : Saridakis, Georgios demande k la Commission de transférer à : Makrimanolakis, Nicolas 6074.rue Hutchison Montréal (Que.) le permis No M-202912 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll.Montréal.Demande de transfert : Kosy Korner Taxi Co.Ltd.demande à la Commission de transférer k: Gagné, Denise 342, rue Cartier, app.10 Laval-des-Rapides (Que.) le permis No M-203128 D-3 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-8, Laval.Demande de transfert : Moquin, Serge demande à la Commission de t ransférer k : Daigneault, Claude 452, rue Latour St-Jean (Que.) le permis No M-204143 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-2, Longueuil.Demande de transfert: Gagné, Jacques demande à lu Commission de transférer à: Bertrand, Jean-Pierre 271, boul.St-Luc St-Luc (Que.) le permis No M-204670 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dan» l'agglomération A-41.St-Jean.Application for transfer: Fecteau Taxi Ltée requests the Commission to transfer to: Chamberland.Claire 5926 des Ecores Street Montreal.P.Q.permit No.M-205701 D-2.which it holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Fountotos.Anargiros requests the Commission to transfer to: Sakellaropoulos, Georgios 4315 L'Esplanade Street.Apt.3 Montreal.P.Q.permit No.M-200204.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll.Montreal.Application for transfer: Ornstein.Samuel requests the Commission to transfer to: Olsauskas, Mecislovas 8048 Querbes Street, Montreal.P.Q.permit No.M-203617 D-5, which he holds, to effect by taxicab in conglomeration A-ll.Montreal.Application for transfer: Gagné.Arthur requests the Commission to transfer to: Mercier, Gilles 3137 Parkville Street Montreal.P.Q.permit No.M-204385.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll.Montreal.Application for transfer: Saridakis, Georgios requests the Commission to transfer to: Makrimanolakis, Nicolas 6074 Hutchison Street Montreal.P.Q.permit No.M-202912.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Kosy Korner Taxi Co.Ltd.requests the Commission to transfer to: Gagné.Denise 342 Cartier Street.Apt.10 Laval-des-Rapides.P.Q.permit No.M-203128 Dr3, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-8, Laval.Application for transfer: Moquin.Serge requests the Commission to transfer to: Daigneault, Claude 452 Latour Street St-Jean, P.Q.permit No.M-204143, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-2, Longueuil.Application for transfer.Gagné, Jacques requests the Commission to transfer to: Bertrund, Jean-Pierre 271 St-Luc Blvd.St-Luc, P.Q.permit No.M-204670, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, St-Jean. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8679 Rôle M-3693 M-205507 forcier, philippe et M-204955 D-4 ladouceur, jean-marie Rôle M-3694 M-202054 burles, charles edward et M-203643 crête, jean-louis Rôle m-3695 m-205073 fauteux, gérard et m-201814 d-3 zidan, sami Rôle M-3696 M-203146 audette, jean-claude et M-206063 golding, jacques Rôle M-3697 M-204849 dalgleish, jack et M-204289 D-3 couture, jean-guy Rôle M-3698 M-205766 cummings, jimmy et M-20G055 marcil, roger Rôle M-3699 M-203612 D-2 taxis philippe harvey inc.et M-203918 D-5 tremblay, joseph-henri Rôle M-3700 24028-v D-l longpré, richard 2812, boul.Rosemont Montréal (Que.) Demande de transfert : Forcier, Philippe demande à la Commission de transférer à: Ladouceur, Jean-Marie 4960, rue Nanterre Pierrefonds (Que.) le permis No M-205507 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-12, Ouest de Montréal.Demande de transfert.: Buries.Charles Edward demande à la Commission de transférer à: Crête, Jean-Louis 8543, rue Brown LaSalle (Que.) le permis No M-202054 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Fauteux.Gérard demande à la Commission de transférer à : Zidan, Sami 1520, boul.Décarie, app.41 St-Laurent (Que.) le permis No M-205073 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Audette, Jean-Claude demande à la Commission de transférer à : Golding, Jacques 2270, rue Duff-Court, app.214 Lachine (Que.) le permis No M-203146 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-12, ouest de Montréal.Demande de transfert: Dalgleish.Jack demande à la Commission de transférer à : Couture, Jean-Guy 1, rue Pilon Beaconsfield (Que.) le permis No M-204849 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-12, Ouest de Montréal.Demande de transfert: Cummings, Jimmy demande à la Coin-mission de transférer à: Marcil, Roger 1763, rue Stratton St-Huhert (Que.) le permis No M-205766 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-2, Longueuil.Demande de transfert: Taxis Philippe Harvey Inc.demande à la Commission de transférer à: Tremblay.Joseph-Henri 7405, rue Montpetit St-Léonard (Que.) le permis No M-203612 D-5 qu'elle détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Nouvelle demande: La partie requérante s'est adressée à la Commission pour obtenir l'autorisation d'effectuer le service suivant: Classe: Transport restreint - service local - Application for transfer: Forcier, Philippe, requests the Commission to transfer to : Ladouceur, Jean-Marie 4960 Nanterre Street Pierrefonds, P.Q.permit No.M-205507, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-12, West of Montreal.Application for transfer: Buries, Charles Edward requests the Commission to transfer to: Crête, Jean-Louis 8543 Brown Street LaSalle.P.Q.permit No.M-202054.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomérat ion A-ll, Montreal.Application for transfer: Fauteux, Gérard requests the Commission to transfer to: Zidam.Sami 1520 Décarie Blvd., Apt.41 St-Laurent, P.Q.permit No.M-205073, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer : Audette, Jean-Claude requests the Commission to transfer to: Golding, Jacques 2270 Duff-Court Street, Apt.214 Lachine, P.Q.permit No.M-203146, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-12, West of Montreal.Application for transfer: Dalgleish, Jack requests the Commission to transfer to : Couture.Jean-Guy 1 Pilon Street Beaconsfield.P.Q.permit No.M-204849.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomérat ion A-12, West of Montreal.Application for transfer: Cummings, Jimmy requests the Commission to transfer to : Marcil, Roger 1763 Stratton Street St-Hubert.P.Q.permit No.M-205766.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-2, Longueuil.Application for transfer: Taxi Philippe Harvey Inc.requests the Commission to transfer to: Tremblay, Joseph-Henri 7405 Montpetit Street St-Léonard, P.Q.permit No.M-203612 D-5.which it holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.New application : The applicant requests from the Commission authorization to effect the following service : Class: Restricted trucking - local service - M ISO QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Rôle M-3701 203-V D-2 MARTEL EXPRESS LIMITÉE 700, rue Principale Farnham, Comté Missisquoi (Que.) Rôle M-3702 592-DYV D-l GORDON MATHIEW McQUILLEN (McQuillen Leasing Reg'd) 359, La Tour St-Jean (Que.) Rôle M-3716 M-202046 BASTAS, DENIS et M-206037 PAPAVASILIOU, DEMETRI Rôle M-3717 M-201048 SERROUR, NÉSSIM et M-206057 TZIOUVARAS.ATHANASE Rôle M-3718 M-205426 LISBERMAN, RALPH et M-206064 Mc GILLIN, KEVIN Service: Monrtéal et tous les endroits situés dans un rayon de cinq (5) milles de ladite ville, pour le transport de produits d'arts graphiques pour le compte de Polychrome Corp.Canada.Modification : La requérante demande que soient réinstallées les clauses suivantes qui ont été annulées le 20 décembre 1972 à la suite d'une ordonnance rendue par la Régie des transports du Québec.En effet la clause j du permis No 203-V doit être réinscrite et modifiée comme suit: Classe: j) Transport général - longue distance -route -Service: ;') De Farnham, Conrobert, Abbotsford, Ste-Pie à Victoriaville.et Québec, et retour via routes régionales 20, 9 et 5.De plus la clause m doit être résintallée dans son intégrité, mais modifiée pour se lire à l'avenir comme suit: Classe: m) Transport restreint - longue distance -route restreinte -Service : m) De plan à plan, entre Farnham, St-Jean et Lacolle, et retour, pour le transport de marchandises et/ou nécessités utilisées par Collins & Aikman Co.Ltd.à l'un ou l'autre de ses plans.(Rapport ci-annexé) Transfert de permis: Gordon Mathiew McQuillen demande de transférer son permis numéro 592-DYV à M.Ronald A.Scobie, lequel opérera sous le nom de: McQuillen Leasing Reg'd.Demande de transfert: Bastas, Denis demande à la Commission de transférer à: Papavasiliou, Demetri 2970, rue Goyer, app.10 Montréal (Que.) le permis No M-202046 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Serrour, Néssim demande à la Commission de transférer à: Tziouvaras, Athanase 5250, avenue du Park, app.5 Montréal (Que.) le permis No M-201048 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Demande de transfert: Lisberman, Ralph demande à la Commission de transférer à: Mc Gillin, Kevin 1400, rue Shevchenko, app.114 LaSalle (Que.) le permis No M-205426 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-ll, Montréal.Service: , - Montreal and ail points located within « radius of five (5) miles from the limits ol said Citv.for the transport of graphic art products, on behalf of Polychrome Corp.Canada.Modification: The applicant requests the reinstatement of the following clauses, which were cancelled on December 20, 1972.pursuant to an order issued by the Québec Transportation Board.Clause ;' of permit No.203-V must in effect be re-entered and modified as follows: Class: (j) General trucking - long distance -route -Service: (j) From Farnham, Conrobert, Abbots-ford, Ste-Pie to Victoriaville, and Québec, and return via regional highways Nos.20, 9 and 5.Moreover, clause m must be reinstated in full, but modified to read henceforth as follows: Class: (m) Restricted trucking - long distance -restricted route -Service : (m) From plant to plant, between Farnham, St-Jean and Lacolle.and return, for the transport of goods and/or commodities used by Collins & Aikman Co.Ltd.at any one of its plants.(Report annexed hereto) Transfer of permit: Gordon Mathiew McQuillen requests the transfer of his permit number 592-DYV to Mr.Ronald A.Scobie.who shall operate under the name of: McQuillen Leasing Reg'd.Application for transfer: Bastas, Denis requests the Commission to transfer to : Papavasiliou, Demetri 2970 Goyer Street, Apt.10 Montreal, P.Q.permit No.M-202046, which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Serrour.Néssim requests the Commission to transfer to : Tziouvaras.Athanase 5250 Park Avenue, Apt.5 Montreal, P.Q.permit No.M-201048.which he holds, to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal.Application for transfer: Lisberman, Ralph requests the Commission to transfer to: Mc Gillin, Kevin 1400 Shevchenko, Apt.114 LaSalle.P.Q.his permit No.M-205426 to effect transport by taxicab in conglomeration A-ll, Montreal. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 novembre 1971,, 100' année, n° AG MM Kôle M-3719 martin, victor et M-201878-D-13 garceau, yvon Rôle M-3720 22031-V-D-l richelieu colis & dispatch service co.(Camille Masseau opérant sous le nom de / Operating under the nama of:) St-Blaise, comté St-Jean (Que.) Rôle M-3721 19749-V-D-6 gérard harbec transport inc.200, rue Comeau Nord Farnham (Que/ Rôle M-3722 23509-V-D-4 TF wilson trucking (québec) limited 580.Rose-de-Lima Montréal (Que.) Rôle M-3723 30006-D-27 TF niagara frontier tariff bureau inc.P.O.Box 184 Buffalo, N.Y.14221 (Membres participants Participating members) Adresse au Québec / Address in Québec a/s: Me Guy l'a rente a'i 1030, rue Cherrier.suite 207 Montreal H2L 1H9 Demande de transfert: Martin, Victor demande à la Commission de transférer à: Garceau, Yvon 5115, rue Charleroi Montréal-Nord (Que.) le permis No M-205172 qu'il détient pour effectuer du transport de taxi dans l'agglomération A-5, Est de Montréal.Transfert de permis: Le requérant-vendeur: Richelieu Colis & Dispatch Service Co.(Camille Masseau opérant sous le nom de:) St-Blaise, Cté St-Jean (Que.) demande à la Commission des transports du Québec d'approuver le transfert de son permis 22031-V en faveur du: Requérant-acquéreur: Richelieu Colis Service Co./ Cie de Service de Colis Richelieu (Paul Besner opérant sous le nom de:) C.P.681.St-Jean (Que.) Le tout conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi des transports.Teneur du permis No 22031-V: o) Transport restreint - service local - a) St-Jean et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite localité, pour le transport par camion panel d'une demi-tonne, de colis, documents, courrier d'une pesanteur maximum de 30 livres, pour le public en général.b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - 6) DTberville, St-Jean et St-Luc à Montréal, et retour, pour le transport par camion panel d'une demi-tonne, de colis, documents, courrier d'une pesanteur maximum de 30 livres, pour le public en général.Nouvelle clause: La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'être autorisée à donner le service de transport suivant: Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - citerne -Service: De Montréal à Farnham, pour le transport de n bunker oil ¦ par camions-citernes, et retour avec marchandise refusée, destinée aux usines de Gutta Percha Industries of Farnham, Limited, et Collins & Aikman situées à Farnham.La requérante désire proposer les nouveaux taux suivants selon l'annexe ci-jointe, pour le transport d'épicerie, de denrée alimentaire et de cargaison générale.Ces taux sont sujets à des frais supplémentaires de 10% lorsqu'un système de chauffage ou de réfrigération est nécessaire.La requérante détient présentement un permis temporaire.Demande de fixation de tarif: Supplément 3 au tarif 261-D (Marchandises générales) Item 4880-A (Reformulé) Item 4890-A (Reformulé) Item 4960-A (Reformulé) Item 4980-A (Annulation) Item 8520 (Addition) Item 9310-A (Addition) Item 12545 (Annulation) Supplément 28 au tarif 270-C (Tarif de fer et d'acier) Item 9295-A (Annulation) Item 9300-A (Annulation) Application for transfer: Martin, Victor requests the Commission to transfer to: Garceau, Yvon 5115 Charleroi Street Montreal-North.P.Q.his permit No.M-205172 to effect transport by taxicab in conglomeration A-5, East of Montreal.Transfer of permit: The applicant-vendor: Richelieu Colis & Dispatch Service Co.(Camille Masseau operating under the name of:) St-Blaise, County of St-Jean, P.Q.requests the Québec Transport Commission to approve the transfer of its permit 22031-V in behalf of: Applicant-purchaser: Richelieu Colis Service Co./Cie de Service de Colis Richelieu (Paul Besner operating under the name of:) P.O.Box 681.St-Jean.P.Q.The whole in conformity with the provisions of section 36 of the Transport Act.Text of permit No.22031-V: (o) Restricted trucking - local service - (a) St-Jean and any point located within a distance of 5 miles from the limits of said locality, for the transport of parcels, documents and mail shipments of a maximum weight of 30 pounds, by half-ton panel truck, for the general public.(6) Restricted trucking - long distance -restricted route - (b) From Iberville.St-Jean and St-Luc to Montreal, and return, for the transport of parcels, documents and mail shipments of a maximum weight of 30 pounds, by half-ton panel truck, for the general public.New clause: The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport service: Class: Restricted trucking - long distance - restricted route - tank -Service: From Montreal to Farnham.for the transport of bunker oil by tank truck, and return with refused goods, to the plants of Gutta Percha Industries of Farnham Limited and Collins & Aikman, located in Farnham.Applicant wishes to propose the following new rates as per attached schedule for the transportation of grocery, foodstuff and general cargo.Subject to 10% surcharge if heater or refer services if required.Applicant under temporary permit.Application for fixation of tariff: Supplement 3 to tariff 261-D (General commodities) Item 4880-A (Reworded) Item 4890-A (Reworded) Item 4960-A (Reworded) Item 4980-A (Cancellation) Item 8520 (Addition) Item 9310-A (Addition) Item 12545-A (Cancellation) Supplement 28 to tariff 270-C (Iron and steel tariff) Item 9295-A (Cancellation) Item 9300-A (Cancellation) S682 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106.No.46 Rôle M-3724 40003-D-72 TF CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' Tariff Bureau Association 4180 Dundas St.West Toronto.Ontario M8X 1X8 (Membres participants Participating members) Rôle M-3725 40003-D-73 TF CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' Tariff Bureau Ass'n.4180 Dundas St.West Toronto.Ontario M8X 1X8 (Membres participants Participating members) Rôle M-372G 2096-A-D-2 TF MÉTROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.1390, William Montréal H3C 1R7 Rôle M-3727 13963-V-D-12 SPEEDWAY EXPRESS LIMITED 20, boul.Marie-Victorin Boucherville (Que.) Supplément 37 au tarif 368 (Tarif de classe et marchandises) Item 10165-A (Annulation) Pour obtenir des renseignements supplémentaires veuillez consulter lesdits suppléments déposés auprès de la Commission des transports du Québec.Le tarif 161-B (annule le tarif No 148-B) MF-I.C.C.aNo 178 comprend toutes les modifications apportées à ce jour et illustre divers frais supplémentaires tels qu'ils sont détaillés dans la demande.Supplement 37 to tariff 368 (Class and commodity tariff) Item 10165-A (Cancellation) For further information please refer to these supplements filed with the Québec Transport Commission.Tariff No.161-B (Cancels tariff No.148-B) MF-I.C.C.No.178 incorporating all changes to date and reflecting certain additional changes as detailed in the application.North American Van Lines Ltd.Les tarifs No E-428 (annule le tarif E-427) et NP-477 (annule le tarif NP-476) illustre des augmentations telles qu'elles sont détaillées dans la demande.Aero Mayflower Transit Co.Ltd.Les tarifs No £-102 (annule le tarif E-101) et NP-552 (annule le tarif NP-551) illustre des augmentations telles qu'elles sont détaillées dans la demande.Métropolitain Provincial (1967) Inc.demande à la Commission des transports du Québec l'autorisation de majorer ses tarifs de 5% sur ses services réguliers vers les banlieues ouest, sud-ouest et est, afin de rencontrer l'accroissement continu de ses frais d'exploitation.La partie requérante demande à la Commission de faire une nouvelle publication amendée de sa requête No 13963-V D-10 qui a été publiée dans la Gazette officielle du Québec, No 38 du 21 septembre 1974.page 6861, sous le No de rôle M-3078, ladite nouvelle publication devant la remplacer et se lire comme suit: La requérante désire que soient enlevées les conditions 4.5 et 6 de son permis portant le numéro 13963-V et qui se lisent comme suit: 4.Le détenteur dudit permis devra payer en plus à la Régie des transports la somme de S5 par voyage aller et retour pour chaque remorque échangée.5.Au cours de la période pendant laquelle ce permis est en vigueur, un rapport ênumé-rant toutes les remorques échangées et utilisées en vertu de ce permis, au cours de toute semaine de son exploitation, doit être remis, ?J)\u201edu|)1,ratu' a la Rigie des transports au 1080, Amherst, Montréal 132 (Que.), et ce.le 3e jour de la semaine qui suit ladite semaine d exploitation.6.Ce rapport ou attestation doit être daté et signé, et doit fournir les renseignements requis sous les rubriques suivantes: a) Date d'entrée de la remorque inter-enangee; 6) Point d'entrée (à la frontière Québec-gouveau-Brunswick et à la frontière des Etats-Unis); 6.c) Date du départ; d) Point de sortie (à la frontière Québec-Nouveau-Brunswick et à la frontière des Etats-Unis); North American Van Lines Ltd.Tariffs No.E-428 (cancels E-427) and NP-477 (cancels NP-476) reflecting increases as detailed in the application.Aero Mayflower Transit Co.Ltd.Tariffs Nos.E-102 (cancels E-101) and NP-552 (cancels NP-551) reflecting increases as detailed in the application.Métropolitain Provincial (1967) Inc.requests authorization from the Québec Transport Commission to apply a 5% increase in rates applicable to its regular services towards the west, southwest and east suburbs in order to meet the continuous increase in operating costs.The applicant requests the Commission to publish a new amended version of its application No.13963-V D-10 which appeared in the Québec Official Gazette number 38, dated September 21, 1974.on page 6861, under roll No.M-3078; the said new publication shall replace the former application and shall read as follows: The applicant wishes conditions 4, 5 and 6 to be deleted from its permit bearing number 13963-V; said conditions read as follows: 4.The holder hereof will in addition pay a sum of $5 per round trip of an interchanged trailer, to the Transportation Board.5.A record of all interchanged trailers utilized under this permit during any week of operation shall be filed, in duplicate, with the Transportation Board, 1080 Amherst, Montreal 132, Québec on the 3rd day of the following week during the time this permit is in force.0.Such record or statement shall be dated, signed and shall list informations under the following headings: (a) Date of entry of interchanged trailer; (5) Port of entry (Québec-New Brunswick border and L'nited States border) ; 6.(c) Date of departure; W) Port of exit (Québec-New Brunswick border and United States border) ; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 10G< année, n° 8683 Rôle M-3728 24001-V-D-l MEUNIER, RÉO Roxton Pond Comté Shefford (Que.) Rôle M -3729 6595-V BERGERON TRANSPORT LTÉE 853-V SUPER TRANSPORT (1966) LTEE 254-V-C-l ACTON VALE TRANSPORT INC.c) Numéro des plaques amovibles RT apposées sur la remorque; /) Lieux d'échange au Nouveau-Bruns-wick et aux Etats-Unis; g) Description de la remorque y compris le numéro des plaques d'immatriculation et le nom du propriétaire; h) Nom des voituriers-rouliers accrédités qui effectuent l'échange; 0 Numéro de série du manifeste, de la feuille de route ou de tout autre document relatif a la cargaison, fournissant les renseignements suivants: 1.Nom et adresse de l'expéditeur; 2.Nom et adresse du destinataire; 3.Lieu d'origine de la cargaison; 4.Destination de la cargaison: 5.Description de la cargaison; 6.Poids de la cargaison : 7.Taux.Ce manifeste, ou cette feuille de route, de même que tout autre document doivent être disponibles au bureau de la compagnie dans la province de Québec, pour consultation par des représentants de la Régie ou par tout autre employé accrédité du gouvernement, durant les heures d'affaires.Nouvelle demande: La partie requérante s'adresse à la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir les services de transport suivants: 1.Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - 1.Service: De Granby à Dunham.Adamsville.Brig-ham, L'Ange-Gardien, Notre-Dame-de-Stan-bridge, Stanbridge-Est.St-Alexandre, Co-wansville, Ste-Sabine, Bedford, Ste-Brigide-d'Iberville, St-Pie.St-Paul.Abercorn.Sut-ton.Iron Hill.West Shefford, Waterloo.Foster.Fulford, St-Césaire.Ste-Angèle, Marie-ville, Pike River.Sabrevois.Henryville.St-Sébastien, St-Armand et Frelisghsburg pour le transport de grains et moulées et engrais chimique en sacs pour le compte de la Coopérative Agricole de Granby.2.Classe: Transport restreint - longue distance - route restreinte - contrat - 2.Service: De la ferme du producteur des paroisses décrites en « 1 » à Granby pour le transport de grains en sac.3.Classe: Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat -3.Service: De St-Hilaire :\\ Granby ou à la ferme des producteurs des paroisses décrites en » 1 « pour le transport de la pulpe de betterave pour le compte de la Coopérative Agricole de Granby.Convocation : Demande de vérification des services de transport fournis par: 254-V Acton Vale Transport Inc.364.boulevard Roxton Case postale 218 Acton Vale.Comté Bagot (Que.) à la demande des parties requérantes.(r) RT revolving plate number affixed to trailer; (/) Point of interchange in the New Brunswick and in the United States; (g) Description of trailer including licence, plates and name of owner; (h) Name of authorized carriers effecting interchange; (?) Serial number of manifest, way-bill or other documents covering the cargo and giving the following informations: 1.Consignor's name and address; 2.Consignee's name and address: 3.Place of origin of cargo; 4.Destination of cargo; 5.Description of cargo; fi.Weight of cargo; 7.Rates.Such manifest or way bill or other documents must be held available at the office of the Company in the Province of Québec for examination during business hours by representatives of the Board or any authorized employees of the Government.New application : The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to provide the following transport services: 1.Class: Restricted trucking - long distance -restricted route - contrat - 1.Service: From Granby to Dunham.Adamsville, Brigham, L'Ange-Gardien.N ot re-Da me-de-Stanbridge.Stan bridge-East.St-Alexandre.Cowansville, Ste-Sabine.Bedford, Ste-Bri-gide-d'Iberville, St-Pie, St-Paul.Abercorn, Sutton.Iron Hill.West Shefford, Waterloo, Foster, Fulford, St-Césaire, Sainte-Angcle.Marieville.Pike River, Sabrevois.Henryville, St-Sébastien.St-Armand and Frelisghsburg for the transport of grain and feed and fertilizers in bags on behalf of Coopérative Agricole de Granby.2.Class: Restricted trucking - long distance -restricted route - contract - 2.Service: From the farm of the producers in the Parishes described in \"1\" to Granby.for the transport of grain in bags.3.Class: Restficted trucking - long distance -restricted route - contract -3.Service: From Saint-Hilaire to Granby or to the farm of the producers in the Parishes described in \"1\", for the transport of beet pulp on behalf of Coopérative Agricole de Granby.Summons: Application for verification of transport services provided by: 254-V Acton Vale Transport Inc.364 Roxton Boulevard Post Office Box 218 Acton Vale, County of Bagot.P.Q.at the request of the applicants. Mis} QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Xorember 10, 1974, Vol.100, Ko.40 Rôle M-3730 2594-V-D-2 GÉRARD GAGNON LTÉE 1550, boulevard de Montarville Boucherville.comté Chambly (Qui.) Rôle M-3731 24034-V-D-l BOULÉ, JEAN-LOUIS 9301.boul.Pie-IX, app.fi Montréal (Que.) Rôle M-3732 1354-DY 117G-DYV D-l AU PAVILLON DE L'AUTO (MONTRÉAL* INC.7665, boul.Lacordaire Montréal (Que.) Modification à la clause: La requérante dont la clause n se lit comme suit: Classe: Transport général - service local -Service : Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite cité.demande que cette clause soit changée pour se lire â l'avenir comme suit: Classe: Transport général - service local -Service : Montréal-Métropolitain, tel que défini par l'arrêté en conseil 4380-73 daté du 28 novembre 1973.Nouvelle demande de permis: La requérante désire être autorisée à faire le transport de marchandises pour le compte de Léo Tremblay Transport Inc.permis 12425-V, conformément aux services autorisés par les clauses suivantes: a, b, c, d, cet/.Teneur desdites clauses: a) Transport restreint - service local - a) Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite cité, pour le transport de ménages.b) Transport restreint - longue distance -route restreinte - 6) De Montréal à St-Jean, et retour, pour le transport de ciment et charbon.c) Transport restreint - longue distance -route restreinte - c) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite cité, et retour (sujet à l'article 44.paragraphe 13 de l'Ordonnance générale sur le camionnage).d) Transport restreint - longue distance -rayon - d) De Montréal-Nord à tous les endroits situés dans un rayon de 150 milles des limites de ladite ville, et retour, pour le transport de matériaux de construction.e) Transport restreint - longue distance -rayon - irrêgulier - e) De Montréal à toutes les localités situées dans un rayon de 400 milles des limites de ladite ville, pour le transport de matériaux de construction, pour les routes, ponts, égouts et bâtiments (à l'exclusion de la brique provenant de Luprairie et Delson et du Siporex en provenance de Delson), et retour avec marchandises refusées ou endommagées./) Transport restreint - longue distance -rayon - /) De Montréal à ailleurs dans la province, et retour, pour le transport de matériaux utilisés dans la construction de ponts, routes, bâtiments, aqueducs, égouts, édifices publics ou privés, installations électriques, installations portuaires ou maritimes.Nouvelle demande: La partie requérante s'adresse k la Commission des transports du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation de donner les services de location suivants: Service 1: Location à court terme (moins d'un an) de véhicules de promenade (automobiles et station-wagons) pour les clients seulement qui attendent une voiture neuve ou dont leur véhicules est en réparation au 7605.boul.Lacordaire.Montréal.P.Q.Modification of clause : , The applicant holding a permit in which clause a reads as follows: ( 'las.1 General trucking - local service -Service: Montreal and ail points located within a distance of five (5) miles from the limits of said City.requests that said clause be modified to read henceforth as follows: Class: General trucking - local service -Service : The Montreal Metropolitan District as defined in Order in Council 4380-73 dated November 28.1973.New application for permit: The applicant requests authorization to provide a transport service on behalf of Léo Tremblay Transport Inc., permit 12425-V.as authorized by the following clauses: a, b, c, d, t and/.Content of the aforesaid clauses: (a) Restricted trucking - local service - (a) Montreal and any point located within a distance of five (5) miles from the limits of said City, for the transport of household goods.(6) Restricted trucking - long distance -restricted route - (b) From Montreal to St-Jean, and return, for the transport of cement and coal.(c) Restricted trucking - long distance -festricted route - (c) From Montreal to any point located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said City, and return (subject to article 44.paragraph 13 of the General Order on Trucking).(d) Restricted trucking - long distance -radius (rf) From Montreal-North to any point located within a radius of 150 miles from the limits of said City, and return, for the transport of building materials.(O Restricted trucking - long distance -radius - irregular - (i du changement de nom.Monsieur Joseph Jean Richard Francoeur.domicilié et résidant à R.R.2, Matapédia.comté et district de Bonaventure, présentera une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer son nom de Joseph Jean Richard Francoeur en celui de Jean Richard.Carleton, ce 29 octobre 1974.Les procureurs du requérant, 58992-45-2-0 Lemarqi an» & Cormui.Joseph Jean Richard Francoeur Notice is hereby given that pursuant to the Change of Name Act, Mr Joseph Jean Richard Francoeur, domiciled and residing on Rural Route 2, Matapédia, County and District of Bonaventure, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Jean Richard.Carleton, October 29, 1974.Lemarquand & Cormier, 58992-45-2 Attorneys for the petitioner. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1G novembre 1971 106< année, n° 46 8721 Gilles Boulianne Avis est par la présente donné que Gilles Boulianne, domicilié au 2, avenue de Barcelone dans la ville de Candiac, district de Montréal, entend présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Gilles de Mahy.Les noms et adresses des personnes vivantes dont le nom peut être changé à la suite de la requête sont les suivants: Yolande Larouche, épouse du requérant, domiciliée au 2, avenue de Barcelone, dans la ville de Candiac, district de Montréal.François Boulianne, fils mineur du requérant, domicilié au 2, avenue de Barcelone dans la ville de Candiac, district de Montréal.Montréal, le 22e jour d'octobre 1974.Les procureurs du requérant.Doheny, Mackenzie, Gbivakes.58962-45-2-0 Gervais & LeMoyne.Joyce Linda Gildenhorn Avis est par les présentes donné que Joyce Linda Gildenhorn, étudiante, domiciliée au 210, rue Dufferin, dans la ville de Hampstead, district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Jovce Linda Gilden.Montréal, le 24 octobre, 1974.Les procureurs de la requérante, 58958-45-2-0 Garonce, Garonce, Costin & Stern.Michael Alexander Iosipovici Avis est par les présentes donné que Michael Alexander Iosipovici, professeur, résidant à 5527, avenue Clan-ranald, à Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour changer son nom en celui de Michael Alexander Florian.Ce changement de nom affectera son épouse Judit Hajnalka Frank.Montréal, le 24 octobre 1974.Le procureur du requérant.58959-45-2-0 Charles Spector.Eugene Jean Kicak Daria Kicak Avis est par les présentes donné selon l'article 5 de la Loi du changement de nom, que Eugene Jean Kicak, ingénieur, et Daria Kicak, ménagère, domiciliés et résidant au 846, 56e Avenue, Cité de Lachine, province de Québec, demanderont au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant leurs noms à Eugene John Kisak et Daria Kisak.Ce changement vaudrait aussi pour leurs enfants mineurs, Alexander Eugene et Nadia Oksana.Montréal, le 9 octobre, 1974.Le procureur des requérants, 58960-45-2-o Roman B.Karpishka.Gilles Boulianne Notice is given that Gilles Boulianne, domiciled at 2 De Barcelone Avenue, City of Candiac, District of Montréal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Gilles de Mahy.The names and addresses of the living persons whose name may be changed pursuant to the application are the following: Y'olande Larouche, wife of the applicant, domiciled at 2 De Barcelone Avenue, City of Candiac, District of Montreal, François Boulianne, minor son of the applicant, domiciled at 2 De Barcelone Avenue, City of Candiac, District of Montreal.Montreal, 22nd day of October, 1974.Doheny, Mackenzie, Grivakes, Gervais & LeMoyne, 58962-45-2-0 Attorneys for the applicant.Joyce Linda Gildenhorn Notice is hereby given that Joyce Linda Gildenhorn, student, domiciled at 210 Dufferin Road, in the Town of Hampstead, District of Montreal, Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for the adoption of an order changing her name to Joyce Linda Gilden.Montreal, October 24, 1974.Garonce, Garonce, Costin & Stern, 58958-45-2-0 Attorneys for the Applicant.Michael Alexander Iosipovici Notice is hereby given that Michael Alexander Iosipovici, professor, residing and domiciled at 5527 Clan-ranald Avenue in Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for a change of name to that of Michael Alexander Florian.Said change of name will affect his wife Judit Hajnalka Frank.Montreal, October 24th, 1974.Charles Spector, 58959-45-2-0 Attorney for the applicant.Eugene Jean Kicak Daria Kicak Notice is hereby given pursuant to section 5 of the Change of Name Act that Eugene Jean Kicak.engineer, and Daria Kicak, homemaker, domiciled and residing at 846 - 56th Avenue, City of Lachine, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing their names to Eugene John Kisak and Daria Kisak and such change shall also avail for their minor children, Alexander Eugene and Nadia Oksana.Montreal, October 9, 1974.Roman B.Karpishka, 58960-45-2-o Attorney for the applicants. 8722 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106.No.46 Dame Anna Retta Bell Avis est par les présentes donné que Dame Anna Retta Bell, née McDonald, épouse séparée des biens de Michael Joseph Léonard, domiciliée au 4280, Broadway, app.15, cité de Lachine, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, la permission de changer son nom en celui de Anna Retta Bell.Beaconsfield, le 22 octobre 1974.Le procureur du requérant.58955-45-2-0 Frank S.Boyd.Dame Anna Retta Bell Notice is hereby given that Dame Anna Retta Bell, née McDonald, wife separate as to property of Michael Joseph Leonard, domiciled at 4280 Broadway, Apt.15, Citv of Lachine, District of Montreal, will ask the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for the permission to change her name to that of Anna Retta Bell.Beaconsfield.this 22nd day of October, 19*4.Frank S.Boyd, 58955-45-2-0 Attorney for the Applicant.Raymond Joseph Coward Avis est par la présente donné que Raymond Joseph Coward, chauffeur de taxi, résidant et domicilié au 266, boulevard Lawrence, appartement 131.dans Greenfield Park, district de Montreal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Raymond Joseph Ward.Montréal, le 20 septembre 1974.Les procureurs du requérant.58956-45-2-0 Kaufman & Posman.Raymond Joseph Coward Notice is given that Raymond Joseph Coward, taxi driver, residing and domiciled at 266 Lawrence Boulevard Apartment 131, of the Town of Greenfield Park, District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, to change his name to Raymond Joseph Ward.Montreal, September 20th, 1974.Kaufman & Posman, 58956-45-2-0 Attorney for the Applicant.Vasile Tcacuic Avis est par les présentes donné que Vasile Tcacuic, enquêteur, domicilié au 317 Penn Road, à Beaconsfield, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de William Caduc, ce décret devant bénéficier à son épouse Andrée Mélodie et à ses enfants, Tanya et Caroline, encore mineurs, domiciliés à la même adresse.Montréal, le 9 octobre 1974.Les procureurs du requérant.58966-45-2-0 Gauthier, Dorais & Hudon.Meguerditch Hrant Balian Avis est par les présentes donné que Meguerditch Hrant Balian.résidant et domicilié au numéro 2065, Duff Court, app.106.en la cité de Lachine, district de Montréal, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil un décret changeant son nom en celui de John Meguerditch Hrant Balian.Le procureur du requérant.137, Notre-Dame.Gérald R.Tabak.Lachine, Que.59058-46-2 Clément Clermont Prenez avis que M.Clément Clermont, représentant, demeurant au numéro 3270, Place de Bienville, Trois-Rivières Ouest, s'adressera au ministre de la justice du Québec, pour demander de changer son nom en celui de Clément Laflamme.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Trois-Rivières.le 30 septembre 1974.Le procureur du requérant.59059-46-2-o Jean Paquin, notaire.Vasile Tcacuic Notice is hereby given that Vasile Tcacuic, investigator, domiciled at civic number 317 Penn Road in Beaconsfield, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to William Caduc, said name to benefit his wife Andrée Meloche and his daughters Tanya and Caroline, still minors, domiciled at the same address.Montreal, October 9, 1974.Gauthier, Dorais & Hudon, 58966-45-2-0 Attorneys for the applicant.Meguerditch Hrant Balian Notice is hereby given that Meguerditch Hrant Balian.residing and domiciled at 2065 Duff Court, Apt.106, in the City of Lachine, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to John Meguerditch Hrant Balian.Gérald E.Tabak, 137, Notre-Dame, Attorney for the applicant.Lachine, P.Q.59058-46-2-o Clément Clermont Notice is hereby given that Mr.Clément Clermont, representative, domiciled at 3270 Place de Bienville, Trois-Rivières West, will present a petition to the Minister of Justice of Québec to change his name to that of Clément Laflamme.This change will not affect any person else than the applicant.Trois-Rivières, September 30th.1974.Jean Paquin, Notary, 59059-46-2-o Attorney for the applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974, 106- année, n° 46 8723 Paul ko! kiv (Kokiw) Irene Alexander Kotkiw (Kokiw) et Donna Alexandra Kotkiw (Kokiw) Avis est par les présentes donné selon l'article 5 de la Loi du changement de nom, que Paul Kotkiw (Kokiw), contremaître en retraite, Irene Alexander Kotkiw (Kokiw), ménagère, et leur fille Donna Alexandra Kotkiw (Kokiw).domiciliés et résidant au 6270, boulevard St-Michel, app.5, cité de Montréal, province de Québec, demanderont au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret changeant leurs noms à Paul Cote, Irene Alexander Cote, et Donna Alexandra Cote.Montréal, le 11 octobre, 1974.Le procureur des requérants.58967-45-2-0 Roman B.Kahpishka.Paul Kotkiw (Kokiw) Irene Alexander Kotkiw (Kokiw) et Donna Alexandra Kotkiw (Kokiw) Notice is hereby given pursuant to section 5 of the Change of Name Act the Paul Kotkiw (Kokiw), retired foreman, and Irene Alexander Kotkiw (Kokiw), homemaker, and their daughter Donna Alexandra Kotkiw (Kokiw), domiciled and residing at 6270 St.Michel Boulevard.Apt.5, City of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing their names to Paul Cote, Irene Alexander Cote, and Donna Alexandra Cote.Montreal, October 11, 1974.Roman B.Karpishka, 58967-45-2 Attorney for the applicant.Aphrodite Perdikis Avis est par les présentes donné que Aphrodite Perdikis, professeur, domiciliée et demeurant au 323.boulevard des Hauteurs, à Village Lafontaine, dans le district de Terrebonne, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Aphrodite Nina Perdikis.Saint-Jérome, le 22 octobre 1974.Les procureurs de la requérante.59060-46-2-o Forget & Rochon.Aphrodite Perdikis Notice is hereby given that Aphrodite Perdikis, teacher, domiciled and residing at 323 Des Hauteurs Boulevard, Village Lafontaine, District of Terrebonne, will make an application to the Lieutenant-Governor in Council for an order to change her name to Aphrodite Nina Perdikis.St.Jérôme, October 22, 1974.Forget & Rochon, 59060-46-2-o Attorneys for petitioner.Joseph, François, Guy, Claude, Yves St-Cyr Prenez avis que Joseph.François, Guy, Claude.Yves St-Cyr résidant et domicilié au 513.avenue Querbes.Montréal, district de Montréal, s'adressera au ministre de la justice pour changer son nom en celui de Joseph.François, Guy, Claude, Yves, Daniel St-Cyr.Montréal, le 25e jour d'octobre 1974.Le procureur du requérant.59061-46-2-o Jean Geoffrion.France Aubin Prenez avis que Mlle France Aubin, domiciliée route rurale no 2, St-Lazare.comté de Bellechasse, présentera une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour que son prénom soit changé pour celui de « Fran-cine ».Les procureurs de la requérante, 59108-46-2-o Turgeon & Brodeur.Joseph, François, Guy, Claude, Yves St-Cyr Notice is hereby given that Joseph, François, Guy, C laude, Yves St-Cyr residing and domiciled at 513 Querbes Avenue, Montreal, District of Montreal, will apply to the Minister of Justice to have his name changed from Joseph, François, Guv, Claude, Yves, Daniel St-Cyr.Montreal, this 25th day of October.1974.Jean Geoffrion, 59061 -46-2-o Attorney for the petitioner.France Aubin Notice is given that Miss France Aubin, domiciled on Rural Route No.2, Saint-Lazare, County of Bellechasse, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing her name to \"Francine\".Tirgeon & Brodeur.59108-46-2 Attorneys for the Petitioner.Domotor Kracsa Avis est par les présentes donné que Domotor Kracsa, garçon de comptoir d'un débit de boisson, domicilié au numéro 3465 Redpath, app.301, dans le district et la ville de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour une autorisation de changer son nom en celui de Denis Kracsa.Le procureur du requérant.59109-46-2-o Myer M.Stern.Domotor Kracsa Notice is hereby given that Domotor Kracsa.Bartender, of 3465 Redpath.Apt.301, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Denis Kracsa.Myer M.Stern, 59109-46-2-o Attorney for Applicant. 8724 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Michel Simard Avis est par les présentes donné que Michel Simard, résidant au 145, avenue Labrecquc en la cité d'Alma, district de Roberval demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom à Michel Girard.Ce changement n'affectera aucune-autre personne que le requérant lui-même.Aima, ce 8 octobre 1974.Les avocats du requérant, Simard, Blanchet.59062-46-2-o Tremblay & Larouche.Michel Simard Notice ie hereby given that Michel Simard, residing at 145 I.abrecque Avenue in the City of Alma, District of Roberval.will petition the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his name to Michel Girard.This change will not affect any person else than the applicant.Alma, October 8th.1974.Simard, Blanchet, Tremblay & Larouche, 59062-46-2-o Attorneys for applicant.Eugene Anthony Zlnay Avis est donné que Eugene Anthony Zlnay, administrateur, résidant et domicilié au 383 Clarke Avenue, cité de Westmount, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom de famille en celui de Eugene Anthony Zinay.ledit changement de nom devra également concerner son épouse, née Teresa Claire Grimard, ainsi que ses enfants mineurs, Martha Ann et Louise, tous des mêmes lieux, à toutes fins que de droit.Montréal, ce 7 novembre, 1974.Le procureur du requérant.59106-46-2-o Donald Kujan.Eugene Anthony Zlnay Notice is hereby given .hat Eugene Anthony Zlnay executive, domiciled and residing at 383 Clarke Avenue, Westmount, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Eugene Anthony Zinay, under the provisions of the Change of Name Act, 13-14 Elizabeth II, Chapter 77, which, change will also benefit his wife born Dame Teresa Claire Grimard, and his minor children Martha Ann and Louise.Montreal, November 7th, 1974.Donald Kujan.59106-46-2-o Attorney for the Petitioner.Israel Birencwajg Avis est par les présentes donné que Israel Birencwajg demeurant au 1432 Chemin Webb, dans la cité de Chomedey, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Eddy Israel Biren et le nom de son épouse Freda Esther, résidant à la même adresse, en celui de Biren lesdits noms servant pour toutes fins légales.Montréal, 7 novembre, 1974.Les procureurs du requérant, Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter, 59107-46-2-o Taviss, Shayne & Levitt.Israel Birencwajg Notice is hereby given that Israel Birencwajg, residing at 1432 Webb Road, in the City of Chomedey, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the adoption of an Order changing his name to that of Eddy Israel Biren and the family name of his wife Freda Esther, residing at the same address, to that of Biren the said names to serve for all legal purposes.Montreal, November 7, 1974.Mendelsohn, Rosentzveig, Shacter, Taviss.Shayne & Levitt.59107-46-2-o Attorneys for Petitioner.Neil Alva Gainfort St.Jean Avis est par les présentes donné que Neil Alva Gain-fort St.Jean, vendeur, demeurant au 344.Caron, Do-rion Gardens, comté de Yaudreuil, province de Québec (district de Montréal), s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Neil Alva Gainfort St.John.Ce changement bénéficiera à son épouse, née Lillian Martha Bradley et à son enfant mineur, James Gainfort St.Jean (St.John), tous de la même adresse.Les procureurs du requérant, 59091-46-2-o Bellibeau, Sauvé & Roy.Neil Alva Gainfort St.Jean Notice is hereby given that Neil Alva Gainfort St.Jean, salesman, residing at 344 Caron Avenue, Dorion Gardens.County of Yaudreuil, Province of Québec (District of Montreal), will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to Neil Alva Gainfort St.John.This change will affect his wife, born Lillian Martha Bradley and his minor child, James Gainfort St.Jean (St.John), all of the same address.Belliveau, Sauvé & Roy, 59091-46-2-o Attorneys for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 16 8725 Nichita Tomescu Avis est donné que Nichita Tomescu, aussi connu sous le nom de Nichita Tomesco, avocat, du 63, avenue Maplewood, Outremont, district de Montréal, entend présenter au lieutenant-gouverneur en conseil une requête afin d'obtenir un décret pour changer son nom en celui de Nikita Tomesco.Montréal, ce 22 octobre 1974.Le procureur du requérant, 59063-46-2-o Bruno Cyr, avocat.Arnold Strong Arnold Strong, gentilhomme, domicilié et résidant au numéro 3380, avenue Ridgewood, app.105, dans les ville et district de Montreal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin d'obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Arnold Chicquin.Ce changement sera applicable également à son épouse, Dame Mary Cella Mathew Chicquin.Montréal, ce 10e jour d'octobre 1974.L'avocat.59114-46-2-0 Bernard Sepinwall.Nichita Tomescu Notice is hereby given that Nichita Tomescu, also known as Nichita Tomesco, Lawyer, of 63 Maplewood Avenue, Outremont, District of Montreal, will present a petition to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Nikita Tomesco.Montreal, October 22nd, 1974.Bruno Cyr, advocate, 59063-46-2-o Attorney for the applicant.Arnold Strong Arnold Strong, gentleman, of the City and District of Montreal, therein residing and domiciled at 3380 Ridgewood Avenue, Apt.105, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing his name to thta of Arnold Chicquin.This change will also be applicable to his wife Dame Mary Cella Mathew Chicquin.Montreal, this 10th day of October, 1974.Bernard Sepinwall, 59114-46-2-0 Attorney.Caisses d'épargne et de crédit Savings and Credit Unions LA CAISSE POPULAIRE DE CHATEAUDUN (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 23 avril 1974, par « LA CAISSE POPULAIRE DE CHATEAUDUN » modifiant son territoire qui était « la paroisse Sainte-Bernadette » en celui de la « Cité du Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Paroisse Saint-Louis-de-France et ville de Trois-Rivières ».Québec, le 29 octobre 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 59099-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE CHATEAUDUN (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on April 23, 1974, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE CHATEAUDUN\" modifying its territory which was \"the Parish of Sainte-Bernadette\", to that of \"City of Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Mar-the-du-Cap-de-la-Madeleine, Parish of Saint-Louis-de-France and City of Trois-Rivières\".Québec, October 29, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59099 Companies and Cooperatives.L'UNION REGIONALE DE GASPE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS (Lot des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 10 juillet 1974, par « L'UNION REGIONALE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU DISTRICT DE GASPE - , changeant son nom en celui de « L'UNION REGIONALE DE GASPE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS \u2022.Québec, le 28 octobre 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 59100-o Albert Jessop.L'UNION REGIONALE DE GASPE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on July 10, 1974, bv \"L'UNION REGIONALE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU DISTRICT DE GASPE\", changing its name to that of \"L'UNION REGIONALE DE GASPE DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS \".Québec, October 28, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59100 Companies and Cooperatives. S726 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1974.Vol.106.No.46 LA CAISSE POPULAIRE ST-HUBERT DE AUDET LA CAISSE POPIL VIRE ST-HUBERT DE AUDET (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 29 mai 1974 par « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-HUBERT DE SPALDING », changeant son nom en celui de « LA CAISSE POPULAIRE DE ST-HUBERT DE AUDET».Quélwc.le 28 octobre 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.59101-o Albert Jessop.[Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on May 29.1974, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-HUBERT DE SPALDING\", changing its name to that of \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-HUBERT DE AUDET\".Québec, October 28.1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 59101 Companies and Cooperatives.Compagnies étrangères Agent Extra-Provincial Companies Agent FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.Avis est donné que.par nouvelle procuration en date du 25 septembre 1974, dont une copie a été transmise au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.M.Peter Corohow, 1768, rue Du Collège, Saint-Laurent, a été nommé, en remplacement de M.Jacques Paquin, avocat.1422.avenue Jacques-Lemaistre, Montréal, agent principal dans la province, de « FORT EDWARD EXPRESS CO.INC.», compagnie étrangère, dûment autorisée à faire affaires dans la provin?e de Q îébec, en vertu des dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Avis est aussi donné qu'en vertu de la nouvelle procuration ci-h lut mentionnée, le bureau principal de ladite compag ie est établi à 1768, rue Du Collège, Saint-Laurent, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compzgnies et coopératives, Albert Jessop.59069-o P.A.88-73 FORT EDWARD EXPRESS CO., INC.Notice is given that, by new power of attorney dated September 25, 1974, a copy of which was transmitted to the Minister of Financial Institutions, Companies and Ccoperatives, Mr.Peter Corobow.1768 Du Collège Street, Saint-Laurent, has been appointed, in replacement of Mr.Jacques Paquin, lawyer, 1422 Jacques-Lemaistre Avenue, Montreal, as chief agent in the Province, of \"FORT EDWARD EXPRESS CO.INC.\".an Extra-Provincial Company, duly authorized to carry on business in the Province of Québec, pursuant to the provisions of the Extra-Provincial Companies Act.Notice is also given that pursuant to the above mentioned new power of attorney, the principal office of the said company is located at 1768 Du Collège Street, Saint-Laurent, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.59069 P.A.88-73 Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses ALLTRANS GROUP OF CANADA LTD.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 21e jour d'octobre 1974.il a accordé un nouveau permis n la compagnie «ALLTRANS HOLDINGS (CANADA) LTD.», l'autorisant à exercer des affaires dans la province, sous son nouveau nom de « ALLTRANS GROUP OF CANADA LTD.», conformément aux dispositions de la Loi des compagnies étrangères.Statuts refondus, 1964.chapitre 282.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.59030-o PA: 27-71 ALLTRANS CROUP OF CANADA LTD.The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on October 21, 1974.he granted a new permit to \"ALLTRANS HOLDINGS (CANADA) LTD.\", authorizing it to carry on business in the Province, under its new name of \"ALLTRANS GROUP OF CANADA LTD.\", in conformity with the provisions of the Extra-Provincial Companies Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 282.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59030 PA: 27-71 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' amiée.n° 46 8727 GATX EQUIPAIENT LEASING LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « G ATX EQUIPMENT LEASING LTD.» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.A.Derek Guthrie.Édifice de la banque Royale, bureau 700, 1.Place Ville-Marie, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à Édifice de la banque Royale, bureau 700, 1, Place Ville-Marie, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, Albert Jessop.59030-o 1356-7722 N.I.C.LEASING, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie «N.I.C.LEASING, INC.* a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est Monsieur Wolfgang Zur Nedden, 204, Elgar Park, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 465.rue St-Jean, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59030-o 1357-6509 NRC, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « NRC, INC.» a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59030-o 1358-1798 GATX EQUIPMENT LEASING TLD.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act, \"GATX EQUIPMENT LEASING LTD.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is M.A.Derek Guthrie.1 Place Ville-Marie, Roval Bank Building, Office 700.Montreal.The principal office of the company in the Province is located at 1 Place Ville-Marie.Royal Bank Building, Office 700, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59030 1356-7722 N.I.C.LEASING, INC.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act, \"N.I.C.LEASING INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purposes of receiving service in proceedings against the said company is Mr.Wolfgang Zur Nedden, 204 Elgar Park.Montreal.The principal office of the company in the Province is located at 465 Saint-Jean Street.Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives.59030 1357-6509 NRC, INC.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act.\"NRC.INC.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is C.T.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is located at 420 Grande-Allée East, Québec, Judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59030 1358-1798 OMNI PROPERTY CONSULTANTS LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « OMNI PROPERTY CONSULTANTS LTD.\u2022 a été autorisée à faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Robert L.Munro.1.Place Ville-Marie, bureau 750.Montréal.OMNI PROPERTY CONSULTANTS LTD.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act, \"OMNI PROPERTY CONSULTANTS LTD.\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is Mr.Robert L.Munro, 1 Place Ville-Marie, Office 750, Montreal. 8728 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi à 1, Place Ville-Marie, bureau 750, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59030-o 1357-9248 The principal office of the company in the Province is located at 1 Place Ville-Marie, Office 750, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59030 1357-9248 Régie de l'électricité et du gaz Electricity and Gas Board GAZ METROPOLITAIN, INC.Avis d'audition publique Avis public est par les présentes donné que « GAZ METROPOLITAIN, INC.», distributeur aux termes de la Loi de la Régie de l'Électricité et du Gaz (S.R.Q.1964, chapitre S7) a, par sa requête en date du 1er novembre 1974, demandé à la Régie de l'Électricité et du Gaz de fixer un ajustement de ses prix comme suite à une majoration des taux de TransCanada PipeLines Limited.La Régie tiendra une séance publique d'audition concernant cette requête mardi, le 19 novembre 1974, à 10 h.30 a.m., dans la salle d'audience de la Régie, située au 2100, rue Drummond.Montréal et toute personne désirant soumettre des représentations quant à ladire requête pourra le faire à cette occasion.Tout intéressé peut obtenir copie de la requête en s'adressant au secrétaire de la Régie de l'Électricité et du Gaz, 2100, rue Drummond, Montréal.Montréal, ce 6e jour de novembre 1974.Le secrétaire, 59093-o Marc B.Boissonnault.GAZ METROPOLITAIN, INC.Notice of public hearing Public notice is hereby given that \"GAZ METROPOLITAIN, INC.\" a distributor as defined under the Electricity and Gas Board Act, (R.S.Q.1964, chapter 87) has, by its petition dated November 1, 1974, requested the Electricity and Gas Board to set an adjustment of its prices following an increase in the rates of TransCanada PipeLines Limited.The Board will hold a public hearing concerning the said application on Tuesday, November 19, 1974, at 10:30 a.m.in the Board's hearing room at 2100 Drummond Street, Montreal, and any person wishing to submit representations concerning the said application may do so at that moment.Any interested person may obtain from the Secretary of the Electricity and Gas Board, 2100 Drummond Street, Montreal, a copy of the Application.Montreal, this 6th day of November, 1974.Marc B.Boissonnault, 59093-o Secretary.LE GAZ PROVINCIAL DU NORD DE QUEBEC LE GAZ PROVINCIAL DU NORD DE QUEBEC Avis d'audition publique Avis est par les présentes donné que « LE GAZ PROVINCIAL DU NORD DE QUEBEC », distributeur aux termes de la Loi de la Régie de l'Électricité et du Gaz (S.R.Q.1964, ch.87) a, par sa requête en date du 7 novembre 1974, demandé à la Régie de l'Électricité et du Gaz d'approuver l'ajustement de ses taux selon le mode décrit dans sa requête en cas de modification dans les tarifs autorisés par l'Office National de l'Énergie et régissant l'achat de gaz par la requérante de ses fournisseurs.La Régie entendra cette requête lors d'une séance d'audition qui aura lieu au Palais de justice, situé au 2, avenue du Palais à Rouyn, jeudi le 21 novembre 1974 à 10.30 heures a.m.où des personnes intéressées pourront faire des représentations.Toute personne désirant obtenir copie de la requête s'adressera au soussigné.Régie de l'Électricité et du Gaz.Le secrétaire, Marc B.Boissonnault, c.a.2100, rue Drummond.Montréal.59103-o Notice of public hearing Notice is hereby given that \"LE GAZ PROVINCIAL DU NORD DE QUEBEC\", a distributor as defined by the Electricity and Gas Board Act (R.S.Q.1964, Ch.87 as amended) has, by its petition dated November 7, 1974, requested the Electricity and Gas Board to approve the adjustement of the Applicant's rates in accordance with the method described in its petition, to apply in the event of any change in the tariffs authorized by the National Energy Board governing the purchase of gas by the Applicant from its suppliers.The Electricity and Gas Board will hear the petition at the Court House, located at 2 Du Palais Avenue, Rouyn, Québec on Thursday, November 21st, 1974 at 10.30 a.m., where all interested persons may make representations.Any person wishing to obtain copy of the petition may apply to the undersigned.Electricity and Gas Board.Marc B.Boissonnault, c.a.Secretary.2100 Drummond Street, Montreal.59103-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉHEC.16 novembre 1974, 106' année, n° 46 S729 Curatelle publique Succession Jean-Paul Milot Succession de Milot, .lean-Paul, en son vivant de 7335, boul.Lacordaire, app.108, St-Léonard, décédé le 7 novembre 1973.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurcnt, Montréal 354, H2N IN6 59070-o Succession Marcel Giroux Succession de Giroux, Marcel, en son vivant de Don-nacona, comté de Portneuf.P.Q., décédé le 3 novembre 1972.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81).le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2N 1N6 59090-o Syndicats professionnels ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.) (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 25 juillet 1974.il a autorisé le changement de nom de « ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC.F.C.A.I.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.) », dont la constitution a été autorisée le 6 juin 1967, avec siège social au numéro 760.boulevard Cré-mazie ouest.Montréal, en celui de « ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.) ».et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus.1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59076-q SP: 44-67 Public Curatorship Estate of Jean-Paul Milot Estate of the late Milot.Jean-Paul, in his lifetime of 7335 Lacordaire Blvd., Apt.108, St-Léonard, deceased November 7, 1973.The undersigned hereby gives notice that under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), he is ex-officio trustee to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim aginst it.The Public Curator of Québec.9310 St-Laurent Blvd., Montreal 354, H2N 1N6 59070-o Estate of Marcel Giroux Estate of the late Giroux.Marcel, in his life time of Donnacona, County of Portneuf, P.Q., deceased Novembers, 1972.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator ok Québec.9310 St-Laurcnt Blvd., Montreal 354, H2N 1N6 59090-o Professional Syndicates ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.) (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on July 25, 1974, he authorized the change of name of \"ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC F.C.A.I.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.)\", of which the incorporation was authorized on June 6.1967.with head office located at 760 Crémazie Boulevard West.Montreal, to that of \"ASSOCIATION DES EMPLOYES DU TRANSPORT DU QUEBEC INC.(BELLECHASSE TRANSPORT INC.)\", the foregoing pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59076 SP: 44-67 8730 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTREAL-EST.POINTE-AUX-TREMBLES INC.{Loi des syndicats professiotinels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 17 octobre 1974, il a autorisé la constitution d'un syndicat professionnel, sous le nom de « L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTREAL-EST.POINTEAUX-TREMBLES INC.», avec siège social situé à Pointe-aux-Trembles, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.Albert Jessop.59112-0 SP: 1354-6981 L'ASSOCIATION DES POMPIERS iii MONTREAL-EST, POINTE-AUX-TREMBLES INC.(Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, on October 17, 1974, he authorized the incorporation of a professional syndicate under the name of \"L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTREAL-EST, POINTE-AUX-TREMBLES INC.\", with head office located in Pointeaux-Trembles, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59112 SP: 1354-6981 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU PAPIER DE CLERMONT (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 26 septembre 1974, il a autorisé le changement de nom de « SYNDICAT NATIONAL DF.S TRAVAILLEURS DES PATES ET PAPIERS DE CLERMONT ».dont la constitution, sous le nom originaire de « SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DE L'INDUSTRIE DU PAPIER DE ST-PHILIPPE DE CLERMONT INC.», a été autorisée le 8 juillet 1937, et dont le siège social est situé à Clermont, en celui de « SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU PAPIER DE CLERMONT et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels, Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59113-0 SP: 1761-1937 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU PAPIER DE CLERMONT (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that on September 26, 1974, he authorized the change of name of \"SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES PATES ET PAPIERS DE CLERMONT\", whose constitution, under the original name of \"SYNDICAT NATIONAL CATHOLIQUE DE L'INDUSTRIE DU PAPIER DE ST-PHILIPPE DE CLERMONT INC.\" was authorized on Julv 8.1937, and whose head office is located in Clermont, to \"SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU PAPIER DE CLERMONT\", the foregoing pursuant to the Professional Syndicates Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.59113 SP: 1761-1937 Demandes à la Legislature Applications to Legislature La Cité de Westmount La Cité de Westmount demandera à l'Assemblée nationale, au cours de sa prochaine session, d'adopter une loi confirmant le titre qu'elle a acquis par expropriation aux lots Nos 380-18 et 380-66 du cadastre officiel de la paroisse de Montréal, division d'enregistrement de Montréal, situés entre le boulevard Dorchester, l'avenue Gladstone, la rue Tuppcr et l'avenue Atwaler, à Westmount.et convertissant en un droit personnel à une indemnité appropriée tout droit de propriété ou autre droit réel dans ou sur lesdits lots qu'on aurait pu faire valoir sans cette loi.Québec, ce 10e jour d'octobre 1974.Les procureurs de la Cité de Westmount, létourneau, StEIN, marseille, 58819-43-1-0 Delisle & Larue.The City of Westmount The City of Westmount will apply to the National Assembly at its next session for an act confirming the title it has acquired through expropriation to lots Nos.3S0-18 and 380-66 of the official cadastre of the Parish of Montreal, registration division of Montreal, situated between Dorchester Boulevard, Gladstone Avenue, Tupper Street and Atwater Avenue, in Westmount, and converting into a personal right to an appropriate indemnity any right of ownership or other real right in or to the said lots that might have been asserted but for such act.Québec City, October 10, 1974.létourneau, stein, marseille, Delisle & Larue, 5S819-43-4-0 Attorneys for the City of Westmount. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n° 46 8731 Ville de Malartic Prenez avis que la ville de Malartic a déposé un projet de loi auprès du comité des bills privés de l'Assemblée nationale pour l'agrandissement de ses limites territoriales.59011-45-4-0 Cliche & Cliche.Ville de Malartic Prenez avis que la ville de Malartic a déposé au secrétariat des Commissions de l'Assemblée Nationale un projet de loi en vue de l'annexion de territoire dans les cantons de Dubuisson et Fournière.59094-46-4-o Cliche & Cliche.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Paroisse de La Visitation-de-la-Pointc-du-Lac Cadastre officiel de la paroisse de La Visitation-de-la-Pointe-du-Lac, municipalité de La Visitalion-de-la-Poinle-du-Lac, division d'enregistrement de Trois-Rivières.Avis est par la présente donné que le lot 265-16 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 octobre 1974.Pour le sous-ministre, 59034-o Norman Lalanne, a.-g.Paroisse de Lachenaie Cadastre officiel de la paroisse de Lachenaie, municipalité de la ville de Lachenaie, division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que la partie restante du lot 53-167 est annulée en vertu de l'article 2174t No.959, Township of Bourlamaque, (959).School taxes: $1,428.24.interest and costs: $202.33.Total: $1.630.57.MM.Y.Lafontaine and M.Desrochers, 838-3rd Avenue, Val-d'Or, P.Q.\u2014Lot No.1156, Township of Bourlamaque, (1156).Municipal taxes: $198.00, school taxes: $106.39, interest and costs: $87.50.Total: $391.89.Mr.John Dolton.Sulcoe Gold Mines Ltd., c/o Gauthier & Pope, 192-3rd Avenue.Timmins, Ont.\u2014 Lot No.38 B, Range VIII.Township of Dubuisson, (38 B).School taxes: $44.88, interest and costs: $46.18.Total: $91.06.Mr.John Dolton.Sulcoe Gold Mines Ltd., c/o Gauthier & Pope, 192-3rd Avenue.Timmins, Ont.\u2014 Lots Nos.41B and 42B.Range VIII, Township of Dubuisson, (41B and 42B).School taxes: $34.27, interest and costs: $45.19.Total: $79.46.Mr.John Dolton.Sulcoe Gold Mines Ltd., c/o Gauthier & Pope, 192-3rd Avenue, Timmins, Ont.\u2014 Lot No.46A, Range VIII, Township of Dubuisson, (46A).School taxes: $37.56.interest and costs: $45.50.Total: $83.06.Mr.Jean-Paul Chabot.R.R.2, Val-d'Or, P.Q.\u2014 Building only on half of lot No.46.Range VIII, Township of Dubuisson, (46J^ M.S.).Municipal taxes: $245.16.school taxes: $334.92, interest and costs: $102.69.Total: $682.77.Mr.Pierre Chabot, R.R.2, Val-d'Or, P.Q.\u2014 West Half of lot No.46, Range VIII, Township of Dubuisson, (46^ O.).Municipal taxes: $103.20, school taxes: $405.23, interest and costs: $89.95.Total: $598.38.Mr.René P.Biais, unknowncd address.\u2014 Part 3 of lot No.48, Range VIII, Township of Dubuisson, (48-3).Municipal taxes: $275.84.school taxes: $319.70, interest and costs: $102.03.Total: $697.57. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974.106' année, n' 46 8765 M.Jean Claude Ross, 1718, 3e Avenue, Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No 54A, subdivision No 6-1, rang VIII, canton Dubuisson, (54-A-6-1), taxes municipales: 8786.80, taxes scolaires: 8688.13, intérêts et frais: 8176.84.Total: $1,651.77.Lavoie & Frères Inc., Landrienne, P.Q.\u2014 Parties des subdivisions Nos 10 et 11 du lot No 54A, rang VIII, et partie de la subdivision No 6 du lot No 105, rang VII, canton Dubuisson, (54-A-10P, 54-A-11P, 105-6P.R.7).Taxes municipales: $352.20.taxes scolaires: $699.79, intérêts et frais: 8132.76.Total: 81,184.75.Lavoie & Frères Inc.Landrienne.P.Q.\u2014 Maison seulement sur la subdivision No 10 du lot 54-A, rang VIII, canton Dubuisson, (54-A-10 M.S.).Taxes municipales: $409.10, taxes scolaires: $832.26.intérêts et frais: $157.39.Total: $1,398.75.M.Raymond Boucher, 1679.3e Avenue.Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No 55-A.subdivision No 7.rang VIII, canton Dubuisson.(55-A-7).Taxes municipales: 8731.11, taxes scolaires: 8862.46, intérêts et frais: $210.10.Total: $1.803.67.M.Ernest Tomlin.62.houl.Hôtel de Ville, Val-d'Or, P.Q.\u2014Lot No 55A.subdivision No 9-1-2, rang VIII.canton Dubuisson, (55-A-9-1-2).Taxes municipales: 8267.60, taxes scolaires: $627.86, intérêts et frais: $106.36.Total: 81.001.82.M.Michel Yakoboski.2072, Papineau, app.40, Montréal, P.Q.\u2014 Lot No 53.partie de la subdivision No 4, rang VII, canton Dubuisson.(53-4P R.7).Taxes municipales: $152.61, taxes scolaires: S131.94.intérêts et frais: 887.69.Total : $372.24.M.Roger Careau.84, rue Marchand, Val-d'Or, P.Q.\u2014Lot No 107.subdivision No 1-13, rang VII, canton Dubuisson, (107-1-13 R.7).Taxes municipales: $102.30, taxes scolaires: $197.86, intérêts et frais: $75.87.Total: 8376.03.M.Pierre Chabot.R.R.2.Val-d'Or.P.Q.\u2014 Lot No 59, rang C.canton Dubuisson.(59 rang C).Taxes municipales: $37.05, taxes scolaires: 8164.63, intérêts et frais: $60.50.Total: $262.18.Le prix d'adjudication de chacun de ces immeubles sera payable immédiatement.Tous les immeubles vendus sont sujets au droit de retrait d'un an.Donné à Val-d'Or.P.Q., ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-quatorze.(Sceau) Le greffier, 59102-46-2-o Paul Lachapellk.Ville de Pierrefonds Avis est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la ville de Pierrefonds, seront vendus à l'enchère publique, en la salle du Conseil de l'Hôtel de ville sise au 11072, boulevard Gouin ouest, MARDI le DIXIÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX heures de I'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais encourus ou qui pourront être encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.Mr.Jean-Claude Ross.1718-3rd Avenue, Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No.54A, Subdivision No.6-1, Range VHI, Township of Dubuisson, (54-A-6-1).Municipal taxes: $786.80, school taxes: $688.13, interest and costs: $176.84.Total: $1,651.77.Lavoie & Frères Inc.Landrienne, P.Q.\u2014 Parts of subdivision Nos.10 and 11 of lot No.54A, Range VIII, and Part of subdivision No.6, of lot No.105, Range VII.Township of Dubuisson, (54-A-10P.54-A-11P, 105-6P.R.7).Municipal taxes: $352.20, school taxes: $699.79, interest and costs: $132.76.Total: $1,184.75.Lavoie & Frères Inc., Landrienne, P.Q.\u2014 Building only on subdivision No.10 of lot 54A, Range VIII, Township of Dubuisson, (54-A-10 M.S.).Municipal taxes: $409.10, school taxes: 8832.26, interest and costs: 8157.39.Total: $1,398.75.Mr.Raymond Boucher, 1679-3rd Avenue, Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No.55A, Subdivision No.7, Range VIII, Township of Dubuisson.(55-A-7).Municipal taxes: $731.11, school taxes: $862.46, interest and costs: $210.10.Total: $1,803.67.Mr.Ernest Tomlin.62 Hôtel de Ville Blvd., Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No.55A, Subdivision No.9-1-2, Range VIII, Township of Dubuisson, (55-A-9-1-2).Municipal taxes: $267.60, school taxes: $627.86, interest and costs: $106.36.Total: $1,001.82.Mr.Michel Yakoboski, 2072, Papineau, Apt.40.Montreal.P.Q.\u2014 Lot No.53.Part of subdivision No.4, Range VII, Township of Dubuisson, (53-4P R.7).Municipal taxes: $152.61.school taxes: $131.94, interest and costs: $87.69.Total: $372.24.Mr.Roger Careau, 84 Marchand Street, Val-d'Or, P.Q.\u2014 Lot No.107, Subdivision No.1-13, Range VII, Township of Dubuisson, (107-1-13 R.7).Municipal taxes: $102.30, school taxes: $197.86, interest and costs: $75.87.Total: 8376.03.Mr.Pierre Chabot.R.R.2.Vald'Or, P.Q.\u2014 Lot No.59.Range C, Township of Dubuisson.(59 Range C).Municipal taxes: $37.05, school taxes: $164.63, interest and costs: $60.50.Total: 8262.18.The purchase price of each of the said immoveables, shall be payable immediately.All the immoveables sold are subject to the one year right of redemption.Given at Val-d'Or, P.Q., this eighth day of November, one thousand nine hundred and seventy-four.(Seal) Paul Lachapelle, 59102-46-2-o Town Clerk.City of Pierrefonds Notice is hereby given that the immoveables des sribed hereinunder, situated in the City of Pierrefonds, will be sold by public auction, in the City Hall of the Citv of Pierrefonds, situated at 10172 Gouin Boulevard West, on TUESDAY, the TENTH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy the payment of the municipal and school taxes with interest, plus the costs which have been or may be incurred, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale. 8766 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16.1974, Vol.106.No.46 Propriétaires Owners Cadastre Subdivision Référence Henriguez.Mme Madeleine J.Brabant, Mme G.- Curatelle Publique.Mayrand, Jacques.4855, Pierre Lauzon Lewis.Ronald.Lagan, Anthony E.La Cie Gestion L.Tremblay Ltée.La Cie Gestion L.Tremblay Ltée.Crown Trust, in Trust.10960 Gouin Lalande, Rodolphe.White.Mrs.Joan A.D., 11851 Pavillon.Mac Ent.Ltd.Mac Ent.Ltd.Mac Ent.Ltd.Mac Ent.Ltd.Mac Ent.Ltd.Roy, Henri-Paul.Roy, Henri-Paul.Roy, Henri-Paul.Roy, Henri-Paul.Mac Ent.Ltd.Mac Ent.Ltd.Engelstein.' Harry'.11955.Pavillon.Cloverlawn Investments Ltd.Rosenberg.Mme Rose.Ross.Roland.12249.Gouin.Baywater Constr.Ltd.Avalon Construction Inc.Wisniowski, Zbigniew W.5012, Perron David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.Caremi, Anstalt - R.R.Ellmenreich Inc., 13013, Gouin Lavoie.Normand.David Bohbot Co.Inc.Handy.John E.4473, Dumas .Leclerc, Jacques, 6987, Marceau Lalande, Jean, 5490, Raymond.Larocque, Jean-Claude, 5357, Des Maçon».Ghirotto, Eddy.Legault, Mme Jeanne.The Seventh Estate Inc., 14100, Pierrefonds- Lacombe.Armand.14427.Gouin.Marcil.Gaétan - Mme Manon R.14455.Gouin.Lacombe, Roland, 14358, Gouin.Quinn, Garry S., 308, Biscayne.Sogesan Constr.Ltd.Bona Realties Ltd.& Tuxana A.G.Bona Realties Ltd.& Tuxana A.G.Finchem, Eric H.14843, Windsor.29\tM\t303 29P\t27\t377 31P\t1\t 32\t65-2\t514 32\t66-2\t693 32\t263\t 32\t264\t 32\t265\t955 37P\t33\t 37\t34\t 37\t35\t1182 37\t458\t 37\t459\t1183 -17\t1\t1334 50\t1-3\t1340 62\t68\t1684 67\t139\t1826 67\t140\t1827 67\t141\t1828 76\t142\t1829 67\t143\t1830 67\t1 14\t1831 67\t146\t1833 67\t149\t1836 67\t151\t1838 67\t182\t1869 67 P\t188\t1875 68\t174\t2013 74P\t72\t2094 75\t9\t2114 76\t33\t2135 70\t120\t2189 77\t206-2\t2447 91\t5\t2774 91\t6-1\t 107\t210\t3577 107\t211\t3578 107\t212\t3579 107\t213\t3580 107\t214\t3581 107\t249\t3582 108\t227\t3583 107\t250\t 108\t226\t 107\t251\t3584 108\t225\t 107\t252\t3585 108\t224\t 107\t253\t3586 108\t223\t 107\t254\t3587 107\t255\t3688 107\t285\t3618 107\t295\t 108\t242\t 107\t293\t3623 108\t22 S\t3829 131\t22\t4452 136\t14\t4539 136P\t15\t 150\t18-27\t4780 150\t38\t4812 151P\t95\t4900 151P\t06\t4903 153\t45\t6016 159\t\t5021 160\t\t6022 164\t7\t6031 169\t86\t5085 169\t334\t5234 172\t36\t5459 172\t177\t6521 173\t7\t5586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8767 Propriétaires Owntrt Cadastre Subdivision Référence Morell, Merrill, 4271, Sunset Dr.Mclnroy.Mrs.Rachel J., 4223, Thorndale Alfred.Abaji.Joly.Paul M., 4428, Tessier.Page.Guy.4440.Ste-Anne.Alfred Abaji.Alfred Abaji.Aval.» Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Anderson, Brendan C.15.367.Estérel- Doneghue.F.R.Earle.Sogesan Constr.Ltd.Lummis, Lance.17061, Omega.Valentine.Jacques.4810.Des Erables.Dugas, L.Armand.Dugas, Vianney.Dugas, Vianney.Bernier 4 Lemieux Ine.Betts.John E., 17513, Chickalo.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.David Bohbot Co.Inc.Richardson, Foster W., 4950.Nanterre.Berlin, Mrs.Irma - « Marna Bear », 4919 .des Sources Valentine.Jacques, 4792, St-Charlea.Bessette, Gilles.4387.Ste-Anne.Karsten, Mrs.E., 14436.Gouin.Sigma Constr.Inc.Sigma Conetr.Inc.Sigma Constr.Inc.Westridge Constr.Inc.H.P.Roy Cie Ltée.Roussianos, Paul et al., 14390, Gouin Léveillé.Jacques, 5130, De Gaulle- Léveillé, Jacques, 5140, De Gaulle.Michaud, Ades.Ma Baie Construction Ltée.Lavoie, Mme Louise, 12905.Gouin.Avalon ConBtr.Inc.Avalon Constr.Inc.Avalon Constr.Inc.Goulet.Benoit.Seiber Dev.Corp.Dieppe Ent.Inc.Dieppe Ent.Inc.Dieppe Ent.Inc.Dieppe Ent.Inc.Dieppe Ent.Inc.Sigma Constr.Inc.Rose Enterprises Ltd.Nicol, Kenneth E.A Ma Baie Yacht Club Inc.Bâtisses seulement, propriété de A Ma Baie Yacht Club Inc., sises sur un lopin de terre de forme «régulière, connu et 174\t178\t5911 178\t238-2\t6497 185\t122\t6955 179\t134\t6600 182\t4\t6774 185\t120\t6953 185\t121\t6954 186P\t79\t7033 186P\t80\t7034 186P\t81\t7035 186P\t82\t7036 186P\t83\t7037 186P\tS 4\t7038 186P\t86\t7039 186P\t86\t7040 186P\t87\t7041 lX.il'\tS8\t7042 186P\t89\t7043 186P\t'.m\t7044 186P\t'H\t7045 186P\t92\t7046 186P\t93\t7047 322\t95\t7134 330\t16\t7174 330\t17\t7175 187\t77\t7376 188\t55\t 188\t9\t7400 188\t10-2\t 194\t176\t7566 194\t207\t7596 194\t206\t7597 194\t209\t7598 194\t826\t7704 107\t207\t8207 108P\t236\t 107P\t208\t8208 107P\t209\t8209 194\t123\t8229 52\t179\t8511 187P\t46\t8580 187P\t47\t 182\t102\t8662 164\t8\t8704 175\t216\t8728 175\t219\t8731 175\t220\t8732 20\t107\t8997 54P\t12\t9004 54\t13\t 164\t1\t9172 194P\t10\t9179 194P\t10\t9180 194P\tn\t 194\t32\t9275 32\t276\t9330 101\t95\t9336 186\t9-2\t9464 186\t19-2\t9466 186P\t27\t9467 237P\t4\t9607 174P\t205\t11287 174\t206\t11288 173\t267\t11301 173\t268\t11302 173\t269\t11303 173\t272\t11306 185\t168\t11327 62\t82\t11346 181\t68\t11356 \t\t278 Buildings only, property of A situated on a parcel of land of Ma Baie Yacht Club Inc., irregular figure, known and 8768 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.16 Propriétaires Owners Cadastre Subdivision Référence désigné comme étant partie de la subdivision numéro un du lot originaire vingt-huit (28 partie 1) propriété de la ville de Pierrefonds, loué à A Ma Baie Yacht Club Inc., et bornée comme suit: au nord-est par partie du lot No 25 propriété des Frères de St-Gabriel ou représentants; au sud-est et dans une autre ligne nord-est par partie du lot No 28-1 propriété des Frères St-Gabriel ou représentants; au sud-ouest, par partie du lot No 29 (rue Rose) et au nord, par la Rivière des Prairies.Mesurant dans la ligne nord-est, trois cent deux pieds (302'), dans laligne sud-est, cent soixante-deux pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pied (162.85'), dans une autre ligne nord-est cinq cent trente-huit pieds et six dixièmes de pied (538.6'), dans une autre ligne sud-est trente pieds (30'), dans la ligne sud-ouest neuf cent soixante-neuf pieds et neuf dixièmes de pied (969.9') ; contenant une superficie de cinquante-huit mille deux cent soixante-treize pieds carrés (58.273 pi.ca.).A distraire l'emplacement de pompage occupé par la ville de Pierrefonds et entouré d'une clôture de « Stelco ».Cet emplacement est décrit comme suit: de figure irrégulière, borné au nord, nord-est, à l'est, au sud-est, sud-ouest et nord-ouest par partie du lot No 28-1.Mesurant dans la ligne nord quatre-vingt-douze pieds et trois dixièmes de pied (92.3'), dans la ligne nord-est quatre-vingt-dix-neuf pieds et cinq dixit mes de pied (99.5').dans la ligne est cent quarante-neuf pieds et sept dixièmes de pied (149.7') suivant une courbe, dans la ligne sud-est quarante pieds et quatre dixièmes de pied (40.4').dans la ligne sud-ouest deux cent quarante pieds et un dixième de pied (240.1') et dans la ligne nord-ouest cinquante-trois pieds et deux dixièmes de pied (53.2').Contenant une superficie d vingt-huit mille six cent cinquante pieds carrés (28,650 pi.ca.) designated as being part of subdivision one of original lot twenty-eight (28 part 1), property of the City of Pierrefonds.rented to A Ma Baie Yacht Club, and bounded as follows: to the northeast, by part of lot No 25, property of Les Frères St-Gabriel or representatives, to the southeast, and in another northeast line, by part of lot 28-1, property of Les rrères St-Gabriel or representatives; to the southwest by part of lot 29 (Rose Street) and to the north, by Rivière des Prairies.Measuring in its northeast line three hundred and two feet (302').in its southeast line, one hu'.,.ed and sixty-two feet and eightv-four hundredths of a foot (162.85'), in another northeast 'line five hundred and thirty-eight feet and six tenths of a foot (538.6'), in another southeast line thirty feet (30').in the southwest line nine hundred and sixty-nine feet and nine tenths of a foot (969.9') ; containing a superficial area of fifty-eight thousand two hundred and seventy-three square feet (58,273 sq.ft.).To be substracted the parcel of land occupied by the City of Pierrefonds for a pumping station and encircled by a \"Stelco\" fence.This site is described as follows: Of irregular figure, bounded to the north, northeast, east, southwest, southeast, and northwest by part of lot 28-1.Measuring in its north line ninety-two feet and three tenths of a foot (92.3') in its northeast ninety-nine feet and five tenths of a foot (99.5'), in its east line one hundred and fourty-nine feet and seven tenths of a foot (149.7') along a curve, in its southeast, fourty feet and four tenths of a foot, (40.4'), in its southwest two \"hundred and fourty feet and one tenth of a foot (240.1') and in its northwest line fifty-three feet and two tenths of a foot (53.2').Containing a superficial area of twenty-eight thousand six hundred and fifty square feet (28,650 sq.ft.).Westridge Construction Inc.Borné en front dans ses lignes nord-ouest par la voie ferrée du Canadien National (P.20), au nord-est par le résidu dudit lot originaire 20, au sud-est et au sud-ouest par le cadastre officiel de la paroisse de St-Laurent, et dans une autre ligne sud-ouest par une autre partie non subdivisée dudit lot originaire 20 (voie ferrée du Canadien National).Cette partie de lot mesure vingt-cinq pieds (25') et deux cent trente-cinq pieds (235') dans ses lignes nord-ouest, deux cent soixante-douze pieds (272') dans sa ligne nord-est.deux cent soixante-quinze pieds et cinq dixièmes de pied (275.5') dans sa ligne sud-est.deux cent quatre-vingt-treize pieds et deux dixièmes de pied (293.2') dans sa ligne sud-ouest, et cinquante pieds (50') dans une autre ligne sud-ouest.Contenant en superficie soixante-dix mille six cents pieds carrés, mesure anglaise.(70,600 pi.ca.plus ou moins).Saratoga Dev.Corp.De figure irrégulière, borné en front à l'ouest par la rue Berry (P.101-4 et 101-48), au nord-est par le lot 95-40 et au sud-est par le lot 101-46.Cette partie de lot mesure quinze pieds et cinq centièmes de pied (15.05 pi.) sur un arc d'un rayon de 100 pieds et cent vingt-trois pieds et trente-deux centièmes de pied (123.32 pi.) enligne droite sur la rue Berry; cent cinq pieds et quatre-vingt-quinze centièmes de pied (105.95 pi.) au nord-est et quatre-vingt-sept pieds et quarante-cinq centièmes de pied (87.45 pi.) au sud-est.Cette partie de lot contient en superficie quatre mille huit cent vingt-huit pieds carrés, mesure anglaise (4,828 pi.ca.).P.20 9000 Bounded in front towards the northwest by the Canadian National Railroad (P.20), towards the northeast by the residue of said original lot 20, towards the southeast and the southwest by the official cadastre for the Parish of St-Laurent, ana in another southwest line by another part of original lot 20 (CNR).This part of lot measures twenty-five feet (25') and two hundred and thirty-five feet (235') in its northwest lines, two hundred and seventy-two feet (272') in its northeast line, two hundred and seventy-five feet and five tenths of a foot (275.5') in its southeast line, two hundred and ninety-three feet and two tenths of a foot (293.2') in its southwest line, and fifty feet (50') in another southwest line.Containing a superficial area of seventy thousand six hundred square feet English mesure, (70,600 sq.ft.more or less).P.101 3187 Of irregular figure, bounded in front towards the west by Berry Street (Pt.101-4 and 101-48); towards the northeast by lot 95-40; and towards the southeast by lot 101-46.This part of lot measures fifteen feet and five hundredths of a foot (15.05 ft.) along a curve of radius of 100 feet and one hundred and twenty-three feet and thirty-two hundredths of a foot (123.32 ft.) being a straight line on Berry Street; one hundred and five feet and ninety-five hundredths of a foot (105.95 ft.) towards the northeast and eighty-seven feet and forty-five hundredths of a foot (87.45 ft.) towards the southeast._ This part of lot contains a superficial area of four thousand eight hundred and twenty-eight square feet, English measure (4,828 sq.ft.).Jacques O'Keefe.Borné en front au sud-ouest par le lot 197-24 (rue), au nord-ouest par la Rivière des Prairies, au nord-est par une partie non subdivisée du lot originaire 196, et au sud-est par le lot 197-40.P.197 7909 Bounded in front towards the southwest by lot 197-24 (Street), towards the northwest by Rivière des Prairies, towards the northeast by an unsubdivided part of original lot 196, and towards the southeast by lot 197-40. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8769 Propriétaires Owners Cadastre Subdivision Référence Cette partie de lot mesure cent quatre-vingt-cinq pieds (185') de profondeur dans sa ligne sud-ouest, quatre-vingt-douze pieds et cinq dixièmes de pied (92.5') plus ou moins sur la Rivière des Prairies dans sa ligne nord-ouest, cent quatre-vingts pieds (180') plus ou moins dans sa ligne nord-est, et quatre-vingt-douze pieds et cinq dixièmes de pied (92.5') dans sa ligne sud-est.Contenant en superficie seize mille sept cent cinquante-cinq pieds carrés, mesure anglaise (16,755 pi.ca.).Albert Mah.Borné au nord-est par le boulevard Gouin (sans désignation cadastrale), dans ses lignes sud, sud-est.nord-est, nord et nord-ouest par une autre partie non subdivisée dudit lot originaire 33 appartenant à Réal Ste-Marie, dans une autre ligne nord-est par des parties des lots 32-281 et 32-231, dans une autre ligne sud-est par le lot 32-22, dans une autre ligne sud-ouest par une autre partie non subdivisée dudit lot originaire 33 (passage) et par des parties des lots 33-1-5, 33-1-3 et par le lot 33-1, et dans une autre ligne nord-ouest par une partie du lot 33-4.Cette partie de lot mesure cinquante et un pieds et deux centièmes de pied (51.02') au nord-est par le boulevard Gouin, trente-deux pieds et trente-huit centièmes de pied (32.38') le long d'une courbe d'un rayon de vingt pieds (20'), dix pieds et quarante-deux centièmes de pied (10.42') étant une ligne droite, trente-huit pieds et vingt-neuf centièmes de pied (38.29') le long d'une courbe d'un rayon de quarante-cinq pieds (45'), deux cent trente-quatre pieds et trente-huit centièmes de pied (234.38') étant une ligne droite, cent sept pieds et trente-quatre centièmes de pied (107.34') le long d'une courbe d'un rayon de soixante-cinq pieds (65'), cent neuf pieds et trente-huit centièmes de pied (109.38') étant une ligne droite dans ses lignes sud, sud-e3t, nord-est, nord et nord-ouest sur la partie du lot originaire 33 appartenant à Réal Ste-Marie, deux cents pieds (200') dans une autre ligne nord-est, cent quatre-vingt-dix-neuf pieds (199') dans une autre ligne sud-est, quatre-vingt-dix-huit pieds et cinquante-huit centièmes de pied (98.58') dans une ligne sud-ouest sur la partie du lot originaire 33 étant le passage privé, quatre cent quarante-cinq pieds et quatorze centièmes de pied (445.14') au sud-ouest, soixante-six pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de pied (66.85') dans une ligne nord-ouest.Contenant en superficie cinquante-cinq mi1 le trois cent cinquante-six pieds carrés, mesure anglaise (55,356 pi.ca.).Saratoga Development.Borné en front au sud-ouest par la rue Raimbault (74-10), au nord-est par une partie non subdivisée du lot originaire 70 et au sud-est par une partie du lot 289-197.Cette partie de lot mesure cent trente-six pieds et dix-huit centièmes de pied (136.18') étant une ligne droite et cinq pieds et cinq centièmes de pied (5.05') le long d'une courbe d'un rayon de quinze pieds (15') dans ses lignes sud-ouest, cent trente-six pieds et deux dixièmes de pied (136.2') au nord-est et vingtrdeux pieds et trente-cinq centièmes de pied (22.35') au sud-est.Contenant en superficie mille cinq cent soixante-neuf pieds carrés, mesure anglaise (1,569 pi.ca.).The Seventy-Seven Corp.Borné au sud-est par une partie non subdivisée dudit lot originaire 77 (voie ferrée du Canadien National), au sud-ouest par une partie non subdivisée du lot originaire 86, au nord-ouest par la Rivière des Prairies, et au nord-est par une partie non subdivisés du lot originaire 76.Cette partie de lot mesure trois (3) arpents de largeur perpendiculaire par des profondeurs de mille cent quarante pieds (1,140') dans sa ligne sud-ouest et mille cent quatre-vingt-dix pieds (1,190') dans sa ligne nord-ouest.Contenant en super- This part of lot measures one hundred and eighty-five feet (185') in depth in its southwest line, ninety-two feet and five tenths of a foot (92.5') more or less in its northwest line, one hundred and eighty feet (180') more or less in its northeast line, and ninety-two feet and five tenths of a foot (92.5') in its southeast line.Containing a superficial area of sixteen thousand seven hundred and fifty-five square feet, English measure (16,755 sq.ft.).P.33 704 Bounded towards the northeast by Gouin Boulevard (no cadastral number), in its south, southeast, northeast, north and northwest lines by another unsubdivided part of said original lot 33 property of Real Ste-Marie, in another northeast line by parts of lots 32-281 and 32-231.in another southeast line by lot 32-22, in another southwest line by another unsubdivided part of said original lot 33 (passage) and by parts of lots 33-1-5.33-1-3 and by lot 33-1, and in another northwest line by part of lot 33-4.This part of lot measures fifty-one feet and two hundredths of a foot (51.02') in its northeast line on Gouin Boulevard, thirty-two feet and thirty-eight hundredths of a foot (32.38') along a curve of a radius of twenty feet (20'), ten feet and forty-two hundredths of a foot (10.42') being a straight line, thirty-eight feet and twenty-nine hundredths of a foot (38.29') along a curve of a radius of forty-five feet (45'), two hundred and thirty-four feet and thirty-eight hundredths of a foot (234.38') being a straight line, one hundred and seven feet and thirty-four hundredths of a foot (107.34') along a curve of a radius of sixty-five feet (65'), one hundred and nine feet and thirty-eight hundredths of a foot (109.38') being a straight line in its south, southeast, northeast, north and nQrthwest lines on the said part of original lot 33 property of Real Ste-Marie, two hundred feet (200') in another northeast line, one hundred and ninety-nine feet (199') in another southeast line, ninety-eight feet and fifty-eight hundredths of a foot (98.58') in one southwest line on the said part of original lot 33 being a passage, four hundred and forty-five feet and fourteen hundredths of a foot (445.14') in another southwest line, and sixty-six feet and eighty-five hundredths of a foot (66.85') in another northwest line.Containing a superficial area of fifty-five thousand three hundred and fifty-six square feet, English measure (55,356 sq.ft.).P.74 2032 Bounded in front towards the southwest by Raimbault Street (74.10), towards the northeast by an unsubdivided part of original lot 70 and towards the southeast by part of lot 289-197.This part of lot measures one hundred and thirty-six feet and eighteen hundredths of a foot (136.18') being a straight line and five feet and five hundredths of a foot (5.85') along a curve of a radius of fifteen feet (15') in its southwest lines, one hundred and thirty-six feet ana two tenths of a foot (136.2') towards the northeast and twenty-two feet and thirty-five hundredths of a foot (22.35') towards the southeast.Containing a superficial area of one thousand five hundred and sixty-nine square feet, English measure (1,569 sq.ft.).P.77 2291 Bounded towards the southeast by an unsubdivided part of said original lot 77 (Canadian National Railroad), towards the southwest by an unsubdivided part of original lot 86, towards the northwest by Rivière des Prairies, and towards the northeast by an unsubdivided part of original lot 76.This part of lot measures three (3) arpents in perpendicular width by depths of one thousand one hundred and forty feet (1,140') in its southwest line, and one thousand one hundred and ninety feet (1,190') in its northwest line.Containing a 8770 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46__ Propriétaires Cadastre Subdivision Référence Owners ficie dix-huit arpents carrés et cinq cent vingt-six millièmes d'arpent carré, mesure anglaise (18.526 arp.ca.).Royal Lavoie, 12907 Gouin.P.101: Bornée au sud-ouest par ladite partie du lot 102 décrite plus bas, au nord-ouest par la rue Duff (101-76 et P.101-94) et dans ses lignes nord-est et sud-est par des parties du lot 101.Cette partie de lot mesure deux cents pieds (200') au sud-ouest et au nord-est par des largeurs de neuf pieds et soixante-cinq centièmes de pied (9.65') au sud-est et neuf pieds et quinze centièmes de pied (9.15') au nord-ouest.Contenant en superficie mille huit cent quatre-vingts pieds carrés, mesure anglaise (1,880 pi.ca.).P.102: Bornée au nord-ouest par les lots 102-19 et 102-18 (rue Duff), au nord-est par la partie du lot 101 décrite plus haut, au sud-est par le résidu dudit lot 102 et au sud-ouest par des parties des lots 106 et 107.Cette partie de lot mesure deux cents pieds (200') de profondeur dans ses lignes sud-ouest et nord-est par une largeur de cent cinq pieds et cinq dixièmes de pied (105.5').Contenant en superficie vingt et un mille cent pieds carrés, mesure anglaise (21,100 pi.ca.).Royal Lavoie.Borné en front au nord-est par la rue Duff (Partie du lot 107), à l'est par le lot 102-19 et par une partie non subdivisée du lot originaire 102, au sud par une partie non subdivisée du lot originaire 106.et à l'ouest par une partie non subdivisée dudit lot originaire 107.Cette partie de lot mesure vingt-neuf pieds et cinq dixièmes de pied (29.5') le long d'une courbe d'un rayon de cent quatre-vingt-cinq pieds (185 ) au nord-est cent soixante-dix-sept pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (177.89') dans sa ligne est, trente pieds (30') dans saligne sud, et cent quatre-vingt-neuf pieds (189') dans sa ligne ouest.Contenant en superficie cinq mille deux cent soixante-quinze pieds carrés, mesure anglaise (5,275 pi.ca.).Arthur Monahan, 181 à 1818 Cap St-Jacques.Borné en front au sud-est par un chemin privé d'une largeur d'environ trente pieds (30') étant une partie non subdivisée dudit lot originaire 237, prise le long de la ligne de division entre les lots 237 et 234-1.au sud-ouest par le chemin Charle-bois (sans désignation cadastrale).et dans ses I ignés nord-ouest-et nord-est par une autre partie non subdivisée dudit lot ori ginaire 237.Cette partie de lot mesure soixante-quinze pieds (75') au sud-est, cent soixante-dix pieds et sept dixièmes de pied (170.7') au sud-ouest, cent quarante et un pieds et cinq dixièmes de pied (141.5') au nord-ouest, et cent soixante^ pieds (160') plus ou moins au nord-est.Contenant en superficie dix-huit mille neuf cents pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise (18,900 pi.ca.).John Smith.Borné au sud par la rue Duff (Partie du lot 107), à l'ouest par la rue Fredmir (Partie du lot 107-246), et au nord-est par le lot 102-32.Cette partie de lot mesure dix pieds et trente-quatre centièmes de pied (10.34') le long d'une courbe d'un rayon de deux cent trente-cinq pieds (235') dans sa ligne sud, vingt-neuf pieds et trois dixièmes de pied (29.3') dans sa ligne ouest, et trente et un pieds et cinq dixièmes de pied (31.5') dans sa ligne nord-est.Contenanten superficie cent cinquante et un pieds carrés, mesure anglaise (151 pi.ca.).superficial area of eighteen square arpents and five hundred and twenty-six thousands of a square arpent, English measure.(18.526 sq.arp.).P.101, P.102 3191 Pt.101: Bounded towards the southwest by said part of lot 102 described hereinunder, towards the northwest by Duff Street (101-76 and Pt.101-94), and in its northeast and southeast lines bv parts of lot 101.Said part of lot measures two hundred feet (200 ) in its southwest and northeast lines by widths of nine feet and sixty-five hundredths of a foot (9.65') in its southeast line and nine feet and fifteen hundredths of a foot (9.15') in its northwest line.Containing a superficial area of one thousand eight hundred and eighty square feet, English measure (1,880 sq.ft.).Pt.102: Bounded towards the northwest by lots 102-19 and 102-18 (Duff Street), towards the northeast by the part of lot 101 described hereinabove, towards the southeast by the residue of said lot 102 and towards the southwest by parts of lots 106 and 207.Said part of lot measures two hundred feet (200') in depth in its southwest and northeast lines by a width of one hundred and five feet and five tenths of a foot (105.5').Containing a superficial area of twenty-one thousand one hundred square feet, English measure (21,100 sq.ft.).P.107 9463 Bounded in front towards the northeast by Duff Street (Part of lot 107), towards the east by lot 102-19 and by an unsubdivided part of original lot 102, towards the south by an unsubdivided part of original lot 106 and towards the west by an unsubdivided part of said original lot 107.This part of lot measures twenty-nine feet and five tenths of a foot (29.5') along a curve of a radius of one hundred and eighty-five feet (185') in its northeast line, one hundred and seventy-seven feet and eighty-nine hundredths of a foot (177.89') in its east line, thirty feet (30') in its south line, and one hundred and eighty-nine feet (189') in its west line.Containing a superficial area of five thousand two hundred and seventy-five square feet, English measure (5,275 sq.ft.).P.237 8166 Bounded in front towards the southeast by a private road measuring thirty feet (30') more or less being an unsubdivided part of said original lot 237 along the division line between lots 237 and 234-1.towards the southwest by Charlebois Road (no cadastral number), in its northwest and northeast lines by another part of said original lot 237.This part of lot measures seventy-five feet (75') in its southeast line, one hundred and seventy feet and seven tenths of a foot (170.7') in its southwest line, one hundred and forty-one feet and five tenths of a foot (141.5') in its northwest line, and one hundred and sixty feet (160') more or less in its northeast line.Containing a superficial area of eighteen thousand nine hundred square feet, more or less, English measure (18,900 sq.ft.).P.107 8776 Bounded towards the south by Duff Street (Part of lot 107), towards the west by Fredmir Street (Part of lot 107-246), and towards the northeast by lot 102-32.This part of lot measures ten feet and thirty-four hundredths of a foot (10.34') along a curve of a radius of two hundred and thirty-five feet (235') in its south line, twenty-nine feet and three tenths of a foot (29.3') in its west line, and thirty-one feet and five tenths of a foot (31.5') in its northeast line.Containing a superficial area of one hundred and fifty-one square feet, English measure (151 sq.ft.). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106- année, n\" 16 8771 Propriétaires Owners Cadastre Subdivision Référence Jacques Valentine.Borné en front au sud-est par la rue Valentine (Partie du lot 187-1-18), au sud-ouest par une partie du lot 188-1-1, au nord-ouest par le lot 187-107 et par une partie du lot 187-106, et au nord-est par une partie des lots 187-106,187-47 et 187-46.Cette partie de lot mesure cent quarante-quatre pieds (144') dans sa ligne sud-est, quatre-vingt-dix pieds (90') dans sa ligne- sud-ouest, cent quarante-quatre pieds et six dixièmes de pied (144.6') dans sa ligne nord-ouest, et quatre-vingt-dix pieds (90') dans sa ligne nord-est.Contenant en superficie douze mille neuf cent soixante et onze pieds carrés, mesure anglaise (12,971 pi.ca.).Sigma Construction Inc.Borné en front au nord-est par le boulevard St-Jean (Partie du lot 166), au sud-est par une partie non subdivisée du lot originaire 167.au sud-ouest par une partie du lot 166-1 et au nord-ouest par une partie non subdivisée du lot originaire 166 appartenant à Adalbert Gerbitz in Trust.Cette partie de lot mesure trois cent sept pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (307.89') au nord-est.trois cent trente-trois pieds et quatre dixièmes de pied (333.4') au nord-ouest, trois cent sept pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (307.89') au sud-ouest, et trois cent trente-trois pieds et six dixièmes de pied (333.6') au sud-est.Contenant en superficie quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-un pieds carrés, mesure anglaise (96,481 pi.ca.).Sigma Construction Inc.De figure irrégulière, bornée en front au nord-est par le lot 166-1 (rue), au sud-est par une partie du lot 168, au sud-ouest par une partie du lot 169 et au nord-ouest par le résidu du lot 166.Cette partie de lot mesure six cent quatre-vingt-cinq pieds (685 pi.) au nord-est.deux cent quatre-vingt-sept pieds et trente-huit centièmes de pied (287.38 pi.) au sud-est et deux cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et sept dixièmes de pied (299.7 pi.) au sud-ouest.Cette partie de lot contient en superficie cent quarante-sept mille pieds carrés, mesure anglaise (147,000 pi.ca.).Sigma Construction Inc.De figure irrégulière, bornée en front au nord-est par la Montée St-Jean (P.167), au sud-est par une partie du lot 169, au sud-ouest par une partie du lot 168-1 (rue) à l'ouest, au nord-ouest et au nord par le lot 167-1 (rue).Mesurant cent dix pieds et quarante-quatre centièmes de pied (110.44 pi.) au nord-est.trois cent trente-deux pieds et un dixième de pied (332.1 pi.) au sud-est.cent six pieds et vingt-quatre centièmes de pied (106.24 pi.) au sud-ouest, vingt-trois pieds et soixante-seize centièmes de pied (23.76 pi.) suivant une courbe d'un rayon de 20 pieds à l'ouest, deux cent quatre-vingt-quinze pieds et quatre-vingt-cinq centièmes de_ pied (295.85 pi.) au nord-ouest, trente-neuf pieds et trois centièmes de pied (39.03 pi.) suivant une courbe d'un rayon de 20 pieds au nord.Cette partie de lot contient en superficie quarante et un mille quatre cent soixante-seize pieds carrés, mesure anglaise (41,476 pi.ca.).Sigma Construction Inc.De figure irrégulière, bornée au nord-est par la Montée St-Jean (P.167), à l'est, au sud-est et au sud par le lot 167-1 (rue), au sud-ouest par une partie du lot 168-1 (rue) et au nord-ouest par une partie du lot 166.P.187 9360 Bounded in front towards the southeast by Valentine Street (Part of lot 187-1-18), towards the southwest by part of lot 188-1-1.towards the northwest by lot 187-107 and by part of lot 187-106 and towards the northeast by parts of lots 187-106.187-47 and 187-46.This part of lot measures one hundred and forty-four feet (144') in its southeast line, ninety feet (90') in its southwest line, one hundred and forty-four feet and six tenths of a foot (144.6') in its northwest line, and ninety feet (90') in its northeast line, Containing a superficial area of twelve thousand nine hundred and seventy-one square feet, English measure.(12,971 sq.ft.).P.166 8916 Bounded in front towards the northeast by St.John's Boulevard (Part of lot 166), towards the southeast by an unsubdivided part of original lot 167, towards the southwest by part of lot 166-1 and towards the northwest by another part of said original lot 166 property of Adalbert Gerbitz in Trust.This part of lot measures three hundred and seven feet and eighty-nine hundredths of a foot (307.89') in its northeast line, three hundred and thirty-three feet and four tenths of a foot (333.4') in its northwest line: three hundred and seven feet and eighty-nine hundredths of a foot (307.890 in its southwest line and three hundred and thirty-three feet and six tenths of a foot (333.6') in its southeast line.Containing a superficial area of ninety-six thousand four hundred and eighty-one square feet.English measure (96,481 sq.ft.).P.166 8917 Of irregular figure, bounded in front towards the northeast by lot 166-1 (street), towards the southeast by part of lot 168, towards the southwest by a part of lot 169 and towards the northwest by the residue of lot 166.This part of lot measures six hundred and eighty-five feet (685 ft.) towards the northeast, two hundred and eighty-seven feet and thirty-eight hundredths of a foot (287.38 ft.) towards the southeast and two hundred and ninety-nine feet and seven tenths of a foot (299.7 ft.) towards the southwest.This part of lot contains a superficial area of one hundred and forty-seven thousand square feet, English measure (147,000 sq.ft.).P.167 8918 Of irregular figure, bounded in front towards the northeast by Montée St-Jean (Pt.167), towards the southeast by part of lot 169, towards the southwest by part of lot 168-1 (street) and towards the west, northwest and north by lot 167-1 (street).This part of lot measures one hundred and ten feet and forty-four hundredths of a foot (110.44') towards the northeast, three hundred and thirty-two feet and one tenth of a foot (332.1') towards the southeast, one hundred and six feet and twenty-four hundredths of a foot (106.24') towards the southwest, twenty-three feet and seventy-six hundredths of a foot (23.76') along a curve of a radius of 20 feet towards the west, two hundred and ninety-five feet and eighty-five hundredths of a foot (295.85') towards the northwest and thirty-nine feet and three hundredths of a foot (39.03') along a curve of a radius of 20 feet towards the north.This part of lot contains a superficial area of forty-one thousand and seventy-six square feet, English measure (41.476 sq.ft.).P.167 8918 Of irregular figure, bounded towards the northeast by Montée St-Jean (Pt.167).towards the east, southeast and south by lot 167-1 (street), towards the southwest by part of lot 168-1 (street) and towards the northwest by part of lot 166. s772_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1974.Vol.106.No.46 Cette partie de lot mesure deux cent cinquante-quatre pieds et cinquante-sept centièmes de pied (254.57 pi.) au nord-est, vingt-trois pieds et soixante-seize centièmes de pied (23.76 pi.) suivant une courbe de 20 pieds de rayon à l'est, deux cent quatre-vingt-quinze pieds et soixante-sept centièmes de pied (295.67 pi.) au sud-est.trente-neuf pieds et six centièmes de pied (39.06 pi.) suivant une courbe de 20 pieds de rayon au sud et deux cent quarante-cinq pieds et soixante-onze centièmes de pied (245.71 pi) au sud-ouest et trois cent trente-trois pieds et six dixièmes de pied au nord-ouest (333.6 pi.).Cette partie de lot contient en superficie quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit pieds carrés, mesure anglaise (82,798 pi.ca.).Sigma Construction Inc.De figure irrégulière, bornée au nord-est par une partie du lot 168-1 (rue), à l'est, au sud-est et au sud par le lot 168-2, au sud-ouest par une partie du lot 169, au nord-ouest par une partie du lot 166.Cette partie de lot mesure deux cent soixante-cinq pieds et soixante-cinq centièmes de pied (265.65 pi.) au nord-est, vingt-trois pieds et soixante-seize centièmes de pied (23.76 pi.) le long d'une courbe de 20 pieds de rayon à l'est, deux cent quarante-cinq pieds et trente-quatre centièmes de pied (245.34 pi.) au sud-est, trente-huit pieds et quatre-vingt-quatre centièmes de pied (38.84 pi.) au sud, deux cent cinquante-neuf pieds et vingt et un centièmes de pied (259.21 pi.) au sud-ouest et deux cent quatre-vingt-sept pieds et trente-sept centièmes de pied (287.37 pi.) au nord-ouest.Cette partie de lot contient en superficie soixante-quinze mille trois cent quatre-vingts pieds carrés, mesure anglaise (75,380 pi.ca.).Sigma Construction Inc.De figure irréfculière, bornée au nord-est par une partie du lot 168-1 (rue), au sud-est et au sud-ouest par une partie non subdivisée du lot 169, à l'ouest, au nord-ouest et au nord par le lot 168-2 (rue).Cette partie de lot mesure quatre-vingt-six pieds et trois dixièmes de pied (86.3 pi.) au nord-est, deux cent quatre-vingts pieds et soixante et onze centièmes de pied (280.71 pi.) au sud-est, quatre-vingt-six pieds et trente-trois centièmes de pied (86.33 pi.) au sud-ouest, vingt-trois pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes de pied (23.98 pi.) à l'ouest suivant une courbe de vingt pieds, deux cent quarante-quatre pieds (244 pi.) au nord-ouest et trente-neuf pieds et six centièmes de pied (39.06 pi.) au nord le long d'une courbe d'un rayon de 20 pieds.Cette partie de lot contient en superficie vingt-neuf mille cinquante-neuf pieds carrés, mesure anglaise (29,059 pi.ca.).The 183 Corporation.Première parcelle: De figure irrégulière, bornée en front au sud-est par le boulevard Pierrefonds (P.183), au sud-ouest par une partie du lot 116, les lots 116-22, 116-16 (rue) et 116-15 du cadastre officiel pour le village de Sainte-Geneviève, au nord-ouest par une partie du lot 119 du cadastre officiel du village de Sainte-Geneviève et au nord-est par les lots 182-3, 182-4 et 182-60.Cette parcelle de terrain mesure quatre cent quatre-vingt-dix pieds et quatre-vingt-douze centièmes de pied (490.92') au sud-est, quatre cent vingt et un pieds et quatre-vingt-neuf centièmes de pied (421.89') au sud-ouest, quatre cent sept pieds et huit dixièmes de pied (407.8') au nord-ouest et deux cent soixante-deux pieds et trente et un centièmes de pied (262.31'J au nord-est.Contenant en superficie 3.37 arpents carrés.This part of lot measures two hundred and fifty-four feet and fifty-seven hundredths of a foot (254.57 ft.) towards the northeast, twenty-three feet and seventy-six hundredths of a foot (23.76 ft.) along a curve of a radius of 20 feet towards the east, two hundred and ninety-five feet and sixty-seven hundredths of a foot (295.67 ft.) towards the southeast, thirty-nine feet and six hundredths of a foot (39.06 ft.) along a curve of a radius of 20 feet towards the south and two hundred and forty-five feet and seventy-one hundredths of a foot (245.71 ft.) towards the southwest, and three hundred and thirty-three (333.6 ft.) towards the northwest.This part of lot contains a superficial area of eighty-two thousand seven hundred and ninety-eight square feet.English measure (82.798 sq.ft.).P.168 8919 Of irregular figure, bounded towards the northeast by par*1 of lot 168-1 (street), towards the east, southeast and south by lot 168-2, towards the southwest by part of lot 169 and towards the northwest by part of lot 166.This part of lot measures two hundred and sixty-five feet and sixty-five hundredths of a foot (265.65 ft.) towards the northeast, twenty-three feet and seventy-six hundredths of a foot (23.76 ft.) along a curve of a radius of 20 feet towards the east, two hundred and forty-five feet and thirty-four hundredths of a foot (245.34 ft.) towards the southeast, thirty-eight feet and eighty-four hundredths of a foot (38.84 ft.) towards the south along a curve of a radius of 20 feet, and two hundred and fifty-nine feet and twenty-one hundredths of a foot towards the southwest and three hundred and fifty-seven feet and five tenths of a foot (357.5 ft.) towards the northwest.This part of lot contains a superficial area of seventy-five thousand three hundred and eighty square feet, English measure (75,380 sq.ft.).P.168 8919 Of irregular figure, bounded towards the northeast by part of lot 16S-1 (street), towards the southeast and southwest by an unsubdivided part of lot 169.towards the west, northwest and north by lot 168-2 (street).This part of lot measures eighty-six feet and three tenths of a foot (86.3 ft.) towards the northeast, two hundred and eighty feet and seventy-one hundredths of a foot (280.71 ft.) towards the southeast, eighty-six feet and thirty-three hundredths of a foot (86.33 ft.) towards the southwest, twenty-three feet and ninety-eight hundredths of a foot (23.98 ft.) towards the west along a curve of a radius of 20 feet, two hundred and forty-four feet (244 ft.) towards the northwest and thirtv-nine feet and six hundredths of a foot (39.06 ft.) towards the north along a curve of a radius of 20 feet.This part of lot contains a superficial area of twenty-nine thousand and fifty-nine square feet, English measure (29,059 sq.ft.).P.183 6849 First parcel: Of irregular figure, bounded in front towards the southeast by Pierrefonds Boulevard (Pt.183), towards the southwest by part of lot 116, lots 116-22.116-16(street, and 116-15 of the official cadastre for the Village of Ste.Geneviève, towards the northwest by part of lot 119 for the Village of Ste.Geneviève and towards to northeast by lots 182-3, 182-4 and 182-60.This said parcel of land measures four hundred and ninety feet and ninety-two hundredths of a foot (490.92') towards the southeast, four hundred and twenty-one feet and eighty-nine hundredths ofa foot (421.89') towards the southwest, four hundred and seven feet and eight tenths of a foot (407.8') towards the northwest and two hundred and sixty-two feet and thirty-one hundredths of a foot (262.31') towards the northeast.Containing a superficial area of 3.37 square arpents.Propriétaires Cadastre Subdivision Référence Owners GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n° 46 8773 Propriétaires Owners Cadastre Subdivision Référence Deuxième parcelle: De figure irrégulière, bornée au nord-ouest par le boulevard Pierrefonds (P.183), au nord-est par une partie du lot originaire 182, les lots 182-10 à 182-13 inclusivement.182-18 à 182-23 inclusivement, 182-34, 182-56, 182-61-1 et une partie du lot 182-61, au sud-ouest par des parties non subdivisées des lots originaires 182, 184 (Paroisse de Sainte-Geneviève), et une partie du lot 116 (Village de Sainte-Geneviève).Cette parcelle de terrain mesure quatre-vingt-dix-huit pieds et soixante-quatre centièmes de pied (98.64') dans une ligne droite et quatre cent quatre-vingt-dix pieds et trente-sept centièmes de pied (490.37') le long d'une courbe d'un rayon de 1,860 pieds sur le boulevard Pierrefonds, deux mille quatre cent quatre-vingt-huit pieds (2,488') au nord-est, deux cent dix pieds (210') et cent soixante-quatorze pieds (174') dans ses lignes sud-est sur le résidu du lot 183, soixante et onze pieds (71') au sud-ouest sur le résidu du lot 183 et deux mille soixante-sept pieds (2,067') dans sa ligne sud-ouest sur la partie du lot 184 (Paroisse de Sainte-Geneviève) et la partie du lot 116 (Village de Sainte-Geneviève).Contenant en superficie 23.6 arpents carrés.Agra Invest.Co.Ltd.De figure irrégulière, étant la plus grande partie de la moitié nord-est du lot originaire 200 situé au sud-est du chemin public, connu sous le nom de boulevard Gouin.Cette partie de lot est bornée en front au nord-ouest par le boulevard Gouin et dans son autre ligne nord-ouest par la partie du lot 200 réservée par Elias Lahaie; au nord-est par ladite partie du lot 200 réservée et pour sa plus grande partie par le lot 198; au sud-est par le cadastre officiel de la paroisse de Pointe-Claire et au sud-ouest par le résidu dudit lot originaire 200.Cette partie de lot mesure cent sept pieds (107 pi.) sur le boulevard Gouin; deux cents pieds (200 pi.) au nord-est sur la partie du lot réservée, quatre mille six cent quatre pieds (4,604 pi.) au nord-est ; deux cent vingt-neuf pieds (229 pi.) au sud-est et quatre mille neuf cent quinze pieds (4,915 pi.) au sud-ouest, cent quatorze pieds (114 pi.) sur la partie du lot réservée.Cette partie de lot contient en superficie un million cinquante et un mille cent cinquante pieds carrés, mesure anglaise (1,051,150 pi.ca.).The Two Hundred Nineteen Corporation.De figure irrégulière, bornée au nord-ouest par les lots 219-50, 219-51 (rue).219-52, 219-53 et 219-54, au nord-est par le résidu du lot 219, au sud-est par le cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne et au sud-ouest par le lot 220 et dans une autre petite ligne sud-ouest par une partie du lot 219-51 (rue).Cette partie de lot mesure deux cent soixante-quinze pieds (275'ï et cent pieds (100') dans ses lignes nord-ouest et vingt-cinq pieds (25') dans sa ligne sud-ouest sur les lots 219-50 à 219-54 inclusivement, quatre mille cinq cent soixante-sept pieds et trois dixièmes de pied (4,567.3') danssaligne nord-est, trois cent soixante-seize pieds (376') dans sa ligne sud-est et quatre mille quatre cent soixante-six pieds (4,466') dans sa ligne sud-ouest.Contenant en superficie 44.15 arpents carrés.Lago Corp.- Canent Realty Co.De figure irrégulière, comprenant toute la partie du lot 229 au sud-est de la route d'accès provinciale consuidant à la route Transcanadienne.Cettedite partie du lot 229 est bornée en front au nord par ladite route provinciale; au nord-est par une partie du lot 228 et dans son autre ligne nord-est par le cadastre officiel de la paroisse St-Anne; au nord-ouest par une partie du lot 228; dans ses lignes sud-est et dans une autre ligne nord-est par le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne et au sud-ouest par le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne.Second parcel: Of irregular figure, bounded towards the northwest by Pierrefonds Boulevard (Pt.183), towards the northeast by part of lot 182, lots 182-10 to 182-13 inclusively, 182-18 to 182-23 inclusively, 182-34.182-56.182-61-1 and part of lot 182-61, towards the southwest by part of lot 182.part of lot 184 (Parish of Ste-Geneviève) and part of lot 116 (Village of Ste-Geneviève).This said parcel of land measures ninety-eight feet and sixty-four hundredths of a foot (98.64') in a straight line and four hundred and ninety feet and thirty-seven hundredths of afoot (490.37') along a curve of a radius of 1,860 feet on Pierrefonds Boulevard, two thousand four hundred and eighty-eight feet (2,488') in is northeast line, two hundred and ten feet (210') and one hundred and seventy-four feet (174') in its southeast lines on the residue of lot 183, seventy-one feet (71') in its southwest line on the residue of lot 183 and two thousand ans sixty-seven feet (2,067') in its southwest line on part of lot 184 (Parish of Ste-Geneviève) and part of lot 116 (Village of Ste-Geneviève).Containing a superficial area of 23.6 square arpents.P.200 7935 Or irregular figure, being the greater northeasterly half of original lot No.200 lying to the southeast of the public road, Gouin Boulevard.This said part of lot 200 is bounded in front towards the northwest by Gouin Boulevard and in its other northwest line by the part of lot 200 reserved by Elias Lahaie, towards the northeast by the part of said lot 200 reserved and for its greater extent by lot 198; towards the southeast by the official cadastre for the Parish of Pointe-Claire and towards the southwest by the residue of said original lot No.200.This said part of lot measures one hundred and seven feet (107 ft.) on Gouin Boulevard; two hundred feet (200 ft.) towards the northeast on the reserve; one hundred and fourteen feet (114 ft.) towards the northwest on the reserve, four thousand six hundred and four feet (4,604 ft.) towards the northeast side; two hundred and twenty-nine feet (229 ft.) on the southeast side and four thousand nine hundred and fifteen feet (4,915 ft.) towards the southwest side.This said part of lot measures one million fifty-one thousand one hundred and fifty square feet, English measure (1,051,150 sq.ft.).P.219 8038 Of irregular figure, bounded towards the northwest by lots 219-50, 219-51 (street), 219-52, 219-53 and 219-54.towards northeast by the residue of lot 219, towards the southeast by the official cadastre for the Parish of Ste-Anne and towards the southwest by lot 220 and in another small southwest line by part of lot 219-51 (street).This part of lot measures two hundred and seventy-five feet (275') and one hundred feet (100') in its northwest lines and twenty-five feet (25') in its southwest line on lots 219-50 and 219-54 inclusively, four thousand five hundred and sixty-seven feet and three tenths of a foot (4,567.3') in its northeast line, three hundred and seventy-six feet (376') in its southeast line and four thousand four hundred and sixty-six feet (4,466') in its southwest line.Containing a superficial area of 44.15 square arpents.P.229 8118 Of irregular figure, all that part of lot 229 lying southeast of the provincial access road leading to the Trans-Canada Highway.Which said part of lot 229 is bounded in front towards the north by the said provincial road; towards the northeast by part of lot 228 and in its other northeast line by the official cadastre for the Parish of Ste.Anne; towards the northwest by part of lot 228; in its southeast lines and in another northeast line by the official cadastre for the Parish of Ste.Anne and towards the southwest by the official cadastre for the Parish of Ste.Anne. 8774_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 10.1074.Vol.100.No.46__ Propriétaires .____ Cadastre Subdivision Référence Owntrt Cettedile partie de lot mesure deux cent deux pieds et trente-trois centièmes de pied (202.33 pi.) le long d'une courbe d'un rayon de 3.874.72 pieds et six cent dix-huit pieds (618 pi.) dans une ligne droite le long de ladite route d'accès provinciale; trois mille trois cent quarante-quatre pieds (3,344 pi.) au nord-est sur le lot 228, cent trente-trois pieds et six dixièmes de pied (133.6 pi.) au nord-ouest sur le lot 228, cent soixante-trois pieds et trois dixièmes de pied (163.3 pi.), cinq cent soixante-sept pieds et sept dixièmes de pieds (567.7 pi.), cent vingt-cinq pieds et sept dixièmes de pied (125.7 pi.) et soixante-dix-neuf pieds et trois dixièmes de pied (79.3 pi.) dans ses lignes nord-est et sud-est sur le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne et quatre mille vingt-neuf pieds (4.029 pi.) au sud-ouest sur le cadastre officiel de la paroisse de Ste-Anne.Cettedite partie de lot 229 contient en superficie cinquante-huit arpents, plus ou moins (58 arp., plus ou moins).Leopold Ladouceur .Borné en front dans sa ligne nord-est par la rue Geneviève (Partie du lot 194-172).au sud-est par une autre partie non subdivisée dudit lot originaire 194, au sud-ouest par une partie du lot 194-166 et par le lot 194-165.et au nord-ouest par une partie des lots 195-113-1 et 194-113.Cette partie de lot mesure cent pieds (100') de largeur per-pendicul lire par des profondeurs de cent quarante-six pieds et cinq dixièmes de pied (146.5') dans sa ligne nord-ouest, et cent trents-huit pieds et soixante-cinq centièmes de pied (138.65') dans sa ligne sud-est.Contenant en superficie quatorze mi'le deux cent cinquante-huit pieds carrés, mesure anglaise (14.258 p.ca.).This part of lot measures two hundred and two feet and thirty-three hundredths of a foot (202.33 ft.) along a curve of a radius of 3.874.72 feet and six hundred and eighteen feet (618') in a straight line along the said provincial access road; three thousand three hundred and forty-four feet (3.344 ft.) towards the northeast on lot 228.one hundred and thirty-three feet and six tenths of a foot (133.6) towards the northwest on lot 228.one hundred and sixty-three feet and three tenths of a foot (163.3 ft.), five hundred and sixty-seven feet and seven tenths of a foot (567.7 ft.), one hundred and twenty-five feet and seven tenths of a foot (125.7 ft.) and seventy-nine feet and three tenths of a foot (79.3 ft.) in its northeast and southeast lines on the official cadastre for the Parish of Ste.Anne and four thousand and twenty-nine feet (4,029 ft.) towards the southwest on the official cadastre for the Pariah of Ste.Anne.This said part of lot 229 contains a superficial area of fifty eight arpents more or less (58 arps more or less).P.194 7439 Bounded in front towards the northeast by Geneviève Street (Part of lot 194-172), towards the southeast by another unsubdivided part of said original lot 194.towards the southwest by part of lot 194-166 and by lot 194-165, and towards the northwest by parts of lots 194-113-1 and 194-113.This part of lot measures one hundred feet (100') in perpendicular width by depths of one hundred and forty-six feet and five tenths of a foot (146.5') in its northwest line and one hundred and thirty-eight feet and sixty-five hundredths of a foot (138.65') in its southeast line.Containing a superficial area of fourteen thousand two hundred and fifty-eight square feet, English measure (14,258 sq.ft.).Les immeubles susdits sont tous du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Geneviève et situés dans la ville de Pierrefonds.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes attachées auxdits immeubles.Donné à Pierrefonds.ce vingt-neuvième jour d'octobre mil neuf cent soixante-quatorze.Le greffier, 59098-46-2-o Gabriel Lecault.The above immoveables are all on the official plan and in the book of reference of the Parish of Ste.Geneviève and situated in the City of Pierrefonds.The said sale will he made with all active and passive servitudes, apparent or occult attached to the said properties.Given at Pierrefonds, this twenty-ninth day of October, one thousand nine hundred ard seventy-foi-r.Gabriel Lecault, 59098-46-2-o City Clerk.Cité de Montréal-Nord Avis public est, par les présentes, donné que les propriétés ci-dessous désignées seront vendues à l'enchère à la Salle du Conseil.11211.rue Hébert.MERCREDI le ONZIÈME jour de DÉCEMBRE 1974.à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires avec intérêts, plus les frais subséquemment encourus, à moins que ces taxes, intérêts et dépens ne soient payés avant la vente.Noms des propriétaires Names of proprietors City of Montreal North Public notice is hereby given that the properties hereinafter described will be sold bv auction at the Office of the Council.11211 Hébert Street, on WEDNESDAY the ELEVENTH day of DECEMBER, 1974.at TEN o'clock in the forenoon to satisfy the payment of the municipal and school taxes plus the costs which shall subsequently be incurred, unless the said taxes, interests and costs be paid before the sale.Cadastre Subdivisions Kenneth Paradis.5 «2 Alliance None Ltd.Ii.7 108 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) J.Gilles Denis.7 339 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106- année, n' 16 8775 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions J.Gilles Denis.7 390 J.Gilles Denis.7 391 J.Gilles Denis.7 392 8 1448 J.Gilles Denis.8 1449 J.Gilles Denis.8 1450 J.Gilles Denis.8 1451 J.Gilles Denis.8 1452 J.Gilles Denis.8 1453 J.Gilles Denis.5 99 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Jean-Claude Couture.20 724 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Jean-Claude Couture.20 725 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Dino Messina.23 238 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Roger Mercier.29 1612 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Lionel Gareau.38 818 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Financement F.T.Inc.38 867-1, 867-2 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Pietro Fratta.86 246, 246 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Ignat Sokyrko.97 337-2, 338-4 (Avec bâtisse dessus érigée) (With building thereon erected) Inconnu - Unknown.115 48-1-2, 53-2 Marcel Chaput.6 77P, 18 5-77P:-Une partie du lot soixante-dix-sept (77P) subdi- 5-77P:-A piece or parcel of land being part of lot sixty-vision du lot original cinq (5) cadastre de la paroisse du Sault- seven (77P) subdivision of original lot five (5) cadastre of the au-Récollet en la municipalité de la cité de Montréal-Nord.Parish of Sault-au-Récollet being part of the City of Montreal De figure rectangulaire.Borné vers le sud-ouest par partie du North.Of rectangular form.Bounded towards the southwest lot 5-15 (rue Allard).vers le nord-ouest par le lot 5-18, vers le by part of lot 5-15 (Allard Street), towards the northwest by nord-est par partie du lot 4-26-2 et vers le sud-est par partie lot 5-18, towards the northeast by part of lot 4-26-2 and dudit lot 5-77.Mesurant vingt-cinq pieds (25') de largeur par towards the southeast by part of said lot 5-77.Measuring une profondeur de quatre-vingt-dix pieds (90') et contenant twenty-five feet (25') in width by a depth of ninety feet (90') une superficie de deux mille deux cent cinquante pieds carrés, and containing an area of two thousand two hundred and fifty mesure anglaise.(2250 p.c.m.a.) square feet, English measure.(2250 s.f.E.m.) Jean Simoneau.20 420P 20-420P:- Une partie du lot quatre cent vingt (420P) sub- 20-420P: - Part of lot four hundred and twenty (420P) division du lot originaire vingt (20) cadastre de la paroisse du subdivision of original lot twenty (20) cadastre of the Parish of Sault-au-Récollet en la municipalité de la cité de Montréal- Sault-au-Récollet being part of the City of Montreal North.Nord.De figure rectangulaire.Borné vers le nord-est par le Of rectangular form.Bounded towards the northeast by lot lot 20-85 (avenue Jules-Auclair) ; vers le sud-est par le lot 20-85 (Jules-Auclair Avenue) ; towards the southeast by loi 20-87 (rue Des Muguets) ; vers ie sud-ouest par partie dudit 20-87 (Des Muguets Street) ; towards the southwest by part of lot 20-420 et vers le nord -ouest par partie du lot 20-435.Me- the said lot 20-420 and towards the northwest by part of lot surant vingt pieds (20') de largeur par une profondeur de qua- 20-435.Measuring twenty feet (20') in width by a depth of tre-vingt-dix pieds (90') et contenant une superficie de mille ninety feet (90') and containing an area of one thousand eight huit cents pieds carrés, mesure anglaise.(1800 p.c.m.a.) hundred square feet.English measure.(1800 s.f.E.m.) Jean Simoneau.20 435P 20-435P: - Une partie du lot quatre cent trente-cinq (435P) 20-435P: - Part of lot four hundred and thirty-five (435P) subdivision du lot originaire vingt (20) cadastre de la paroisse subdivision of original lot twenty (20) cadastre of the Parish du Sault-au-Récollet en la municipalité de la cité de Montréal- of Sault-au-Récollet being part of the City of Montreal North.Nord.De figure rectangulaire.Borné vers le nord-est par le Of rectangular form.Bounded towards the northeast by lot S776 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1971, Vol.106, No.17 Noms des propriétaires Names of proprietors Cadastre Subdivisions lot 20-85 (avenue Jules-Auclair); vers le sud-est par partie du lot 20-420; vers le sud-ouest par partie dudit lot 20-435 et vers le nord-ouest par le lot 20-88 (avenue Jules-Auclair).Mesurant vingt pieds (20') de largeur par une profondeur de quatre-vingt-dix (90') et contenant une superficie de mille huit cents pieds carrés, mesure anglaise.(1800 p.c.m.a.) 20-85 (Jules-Auclair Avenue) ; towards the southeast by part of lot 20-420; towards the southwest by part of said lot 20-435 and towards the northwest by lot 20-88 (Jules-Auclair Street).Measuring twenty feet (20') in width by a depth of ninety feet (20') in width by a depth of ninety feet (90') and containing an area of one thousand eight hundred square feet, English measure.(1800 s.f.E.m.) Maurice Pardovani.78;-Le lot originaire soixante-dix-huit (78) cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet en la municipalité de la cité de Montréal-Nord.De figure irrégulière moins la partie vendue à la cité de Montréal-Nord pour l'élargissement du boulevard Gouin et contenant une superficie de quatre mille deux cent cinquante pieds carrés, plus ou moins, mesure anglaise.(4250 p.c.m.a.) (Avec bâtisse dessus érigée) 78 78:-The original lot seventy-eight (78) cadastre of the Parish of Sault-au-Récollet being part of the City of Montreal North.Of irregular form, containing an area of four thousand two hundred and fifty square feet more or less, English measure, less the part sold to the City of Montreal North for the widening of Gouin Boulevard (4250 s.f.E.m.) (With building thereon erected) Inconnu - Unknown.95P:-Une partie du lot originaire quatre-vingt-quinze (95P) cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet en la municipalité du Sault-au-Récoîlet en la municipalité de la cité de Montréal-Nord.De figure rectangulaire.Borné vers le sud-est par partie dudit lot 95 (boulevard Gouin) ; vers le sud-ouest par partie du lot 95-1; vers le nord-ouest et le nord-est par partie dudit lot 95.Mesurant dix pieds (10') de largeur par une profondeur de cent pieds et soixante-quinze centièmes de pied (100.76') et contenant une superficie de mille sept pieds et cinq dixièmes mesure anglaise.(1007.5 p.c.m.a.) 88 95P: - Part of original lot ninety-five (95P) cadastre of the Parish of Sault-au-Récollet being part of the City of Montreal-North.Of rectangular form.Bounded towards the southeast by part of said lot 95 (Gouin Boulevard) ; towards the southwest by part of lot 95-1: towards the northwest and northeast by another part of said lot 95.Measuring ten feet (10') in width by a depth of one hundred feet and seventy-five hundredths of a foot (100.75') and containing an area of one thousand seven square feet and five tenths, English measure.(1007.5 s.f.E.m.) Les immeubles susdits sont tous du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet et situés dans la cité de Montréal-Nord.Ladite vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, attachées auxdits immeubles.Donné en la cité de Montréal-Nord, ce lie jour du mois de novembre 1974.Le Greffier, 59104-46-2-o Aline Ouimet.The above immoveables are all in the plan and book of reference of the Parish of Sault-au-Récollet and situated in the City of Montrea INorth.The said sale will be made with all active and passive servitudes apparent or occult, attached to the said properties.Given at the City of Montreal North, this 11th day of November, 1974.Aline Ouimet, 59104-46-2-o City Clerk.Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act LAVE-ALTO DEUX MINUTES INC.TWO MINUTES CAR WASH INC.Avis est donné que la compagnie « LAVE-AUTO DEUX MINUTES INC.\u2014TWO MINUTES CAR WASH INC », constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies par lettres patentes en date du 4 octobre 1966, avec siège social au numéro 347, rue de l'Espinay, Québec, a été dissoute le 25 septembre 1974, en vertu de la Loi de la liquidation des compagnies.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.59075-o 4015-66 LAVE-AUTO DEUX MINUTES INC.TWO MINUTES CAR WASH INC.Notice is given that \"LAVE-AUTO DEUX MINUTES INC.\u2014TWO MINUTES CAR WASH INC.\", incorporated under Part I of the Companies Act by letters patent dated October 4.1966.with head office located at 347 De l'Espinay Street, Québec, was dissolved on September 25, 1974, pursuant to the Wind-ing-Up Act.59075 , Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.4015-66 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1971, 106' année, n\" 16 8777 Ministère de l'Éducation Department of Education Municipalité scolaire Cowansville Demande est faite de changer les limites de la municipalité scolaire Cowansville en vertu de l'article 46 de la Loi de l'instruction publique, pour protestants au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique, de façon à en détacher le territoire suivant, faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de St-Michel-de-Rou-gemont et de la paroisse de St-Jean-Baptiste dans le comté de Rouville ainsi que de la paroisse de St-Damase dans le comté de St-Hyacinthc: a) les rangs suivants: Pointe de la Montagne Petit Rang Caroline Rangs des Dix Terres Vingt de Corbin Dix de Corbin Rang de la Caroline 6) les parties de rangs suivants: Rang Double, Côté-Ouest lots 478, 480 à 542 inclusivement Rang Double, Côté-Est lots 540 à 597 inclusivement Rang du Cordon lots 481 à 508 inclusivement Rang Corbin lot 292 Rang les Soixante lots 462 à 474 inclusivement.Cowansville School Municipality Application is hereby made to alter the boundaries of the Cowansville School Municipality pursuant to section 46 of the Education Act, for Protestants, within the meaning of section 49 of tl e Education Act, in order to detach therefrom the following territory, forming part of the official cadastre for the Parish, of St-Michel-de-Rougemont and the Parish of St-Jean-Baptiste in the County of Rouville as well as for the Parish of Saint-Damase in the County of St-Hyacinthe: (a) The following Ranges: Pointe de la Montagne Petit Rang Caroline Rangs des Dix Terres Vingt de Corbin Dix de Corbin (b) The following parts of Ranges: Rang Double, Côté-Ouest (West side) lots 478, 480 to 542 inclusive Rang Double, Côté-Est (East side) lots 540 to 597 inclusive Rang du Cordon lots 481 to 508 inclusive Rang Corbin lot 292 Rang les Soixante lots 462 to 474 inclusive.59089-46-2-o Le minisire de l'éducation, François Cloutier.59089-46-2-O François Cloutier, Minister of Education.Nomination Appointment Président d'élection Il a plu à son honneur le lieutenant-gouverneur en conseil de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif, par commission sous le grand sceau, de faire, pour remplir la charge de président d'élection, la nomination suivante : Returning-Officer His Honour the Lieutenant-Governor in Council has been pleased, with, the advice and consent of the Executive Council, to appoint by commission under the Great Seal, to fill the office of returning-officer, the person whose name follows: District électoral Electoral district Nom, prénoms Name.Christian names Profession ou occupation Profession or calling Domicile Champlain.Rivard, Madame Annette C.(1) Madame / Mrs.Saint-Maurice.(1) En remplacement de monsieur Jean Beaudin, démissionnaire./ In place of Mr.Jean Beaudin, resigner.Québec, le 4 novembre 1974.Le président général des élections.Juge de la Cour provinciale, 59077-o François Drouin.Québec, November 4, 1974.François Drouin, Judge of the Provincial Court, 59077-o The Chief Returning Officer. 8778 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1971, Vol.106, No.16 Vente d'effets non réclamés La Cie Messageries CP limitée Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de janvier 1974, et non réclamés aux bureaux des « CP Express Limitée >\u2022 à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à 11 heures du matin, le 5e jour de décembre, 1974, à moins que lesdites effets ne soient réclamés et que tous les frais soient payés avant cette date.Le vice-président, 5S702-42-6-o W.M.Riley.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.CHICOUTIMI Fieri Facias de Terris No sherif 424-74, ( T A LAURENTIENNE COM-No C.S.43-641.< *-> PAGNTE MUTUELLE D'AS-l SURAXCE, corporation légalement constituée ayant son siège social à 500 est, Grande-Allée, Québec 4, P.Q., demanderesse, rs PATRICK VILLENEUVE, domicilié à 410, m.- Levis, Chicoutimi, P.Q., défendeur, et LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Chicoutimi, mis en cause.« Un emplacement situé en la cité de Chicoutimi, se composant de la subdivision un lot originaire cent trente-cinq et de la subdivision sept lot originaire cent trente-deux et du lot douze cent soixante-dix-sept (135-1, 132-7 et 1277) au cadastre officiel de la ville de Chicoutimi, avec bâtisses dessus construite, circonstances et dépendances.Sauf réserve de la servitude existant en faveur de la partie non subdivisée dudit lot cent trente-deux à l'est du terrain ci-dessus décrit.» Pour être vendus au bureau du registrateur de la division d'enregistrement de Chicoutimi.au Palais de Justice de Chicoutimi, JEUDI le DIX-NEUVIÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX 1 \u2022cures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du shérif.Guy Vallée.Chicoutimi, le 8 novembre 1974.59097-o Sale of Unclaimed Baggage CP Express Limited Notice is herebv given that all goods received previous to the first day \"of January, 1974, still remaining unclaimed in the offices of the \"CP Express Limited at different points in the Province of Québec, will be sold at public auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 189 Queen Street East, loron-to, Ontario, at 11:00 o'clock in the forenoon, on the fifth day of December, 1974, unless same shall be called for before that date and all charges paid thereon.W.M.Riley, 58702-42-6-O Vice-President.Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.CHICOUTIMI Fieri Facias de Terris No.Sheriff 424-74,( THE LAURENTIAN MU-S.C.No.43-641.< J- TUAL ASSURANCE COM-v PANY, a corporation legally incorporated having its head office at 500 Grande-Allée East, Québec 4, P.Q., plaintiff, vs PATRICK VILLENEUVE, domiciled at 410 Levis Street, Chicoutimi, P.Q., defendant, and THE REGISTRAR for the Chicoutimi Registration Division, mis en cause.\"An emplacement located in the City of Chicoutimi, comprising subdivision one of original lot one hundred thirty-five and subdivision seven of original lot one hundred thirty-two and lot one thousand two hundred seventy-seven (135-1, 132-7 and 1277) on the official cadastre for the City of Chicoutimi, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.Excluding reservation of the existing servitude in behalf of the nonsubdivided part of said lot one hundred thirty-two on the east of the land hereinabove described.\" To be sold at the Office of the Registrar for the Chicoutimi Registration Division, at the Court House of Chicoutimi, on THURSDAY, the NINETEENTH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Guy Vallée, Sheriff's Office.Assistant Sheriff.Chicoutimi, November 8, 1974.59097 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 novembre 1974, 106' année.»' 16 8779 HAUTERIVE Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Hauterive i Corporation municipale de No 14200X v-* RAGUENEAU, demandeur, vs DA-l ME PHILIPPE GAUTHIER, défenderesse.Affectant une propriété immobilière étant une partie du lot 21, Rang Rivière-aux-Outardes, canton Mani-couagan, ayant une dimension de 100' par 100' pour une superficie de 10,000 pieds carrés, étant la demi-sud-ouest du lot 21 borné à l'ouest par le chemin public, à l'est par la propriété d'Alfred Morin, au nord par la propriété d'Alfred Morin et au sud par le lot 22.avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances, tel que décrit aux plan et livre de renvoi de canton Manicouagan, municipalité de Pointc-aux-Outardes.Pour être vendu au bureau du régistrateur de la première division d'enregistrement de Saguenay.au Palais de Justice de Baie-Comeau, MARDI, le DIX-SEPTIÈME jour du mois de DÉCEMBRE 1974, à onze heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif adjoint.Charlotte Bergeron.Baie-Comeau, ce 16 novembre 1974.59065-o KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Kamouraska ( T A CAISSE POPULAIRE No 250-05-000089-74.< DE ST-ANTONIN.cor-l poration légalement constituée avec siège social de St-Antonin, demanderesse, vs FERNAND J.A.PELLETIER, St-Antonin.Comté de Rivière-du-Loup, défendeur.« Un terrain contenant environ cent cinq pieds (105') de front est-ouest sur cent cinquante pieds (150') de profondeur, mesures anglaises, borné au nord au chemin public, au sud et à l'ouest à Joseph Pellerin et à l'est à Gilles Plante; lequel terrain fait partie du numéro cent soixante-cinq (ptie 165) du cadastre de St-Antonin, avec les bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement division de Témiscouata, situé à 65A, rue Iberville.Rivière-du-Loup, le DIX-HUmÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif.Bureau du Shérif, Maurice Morin.Rivière-du-Loup, ce 6 novembre 1974.59066-o HAUTERIVE Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Hauterive i MUNICIPAL CORPORATION OF No.14200X JV1 RAGUENEAU.plaintiff, vs MRS.I PHILIPPE GAUTHIER, defendant.Concerning an immoveable property being a part of lot 21, Rivière-aux-Outardes Range, Township of Manicouagan, measuring 100' by 100' for an area of 10,000 square feet, being the southwest half of lot 21, bounded on the west by the public road, on the east by the property owned by Alfred Morin.on the north by the property owned by Alfred Morin and on the south by lot 22.with the building erected thereon, appurtenances and dependencies, as described on the plan and in the book of reference for the Township of Manicouagan, Municipality of Pointe-aux-Outardes.To be sold at the Office of the Registrar for the First Registration Division of Saguenay, in the Baie-Comeau Court House, on TUESDAY, the SEVENTEENTH day of DECEMBER, 1974.at ELEVEN o'clock in the forenoon.Charlotte Bergeron, Assistant Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Baie-Comeau, November 16, 1974.59065 KAMOURASKA Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Kamouraska ( T A CAISSE POPULAIRE No.250-05-000089-74.S *-> DE ST-ANTONIN, a cor-' poration legally incorporated having its head office in Saint-Antonin, plaintiff, vs FERNAND J.A.PELLETIER.Saint-Antonin, County of Rivière-du-Loup, defendant.\"A piece of land measuring approximately one hundred five feet (105') in front from east to west by one hundred fifty feet (150') in depth, English measure, bounded on the north by the public road, on the south and west by the property of Joseph Pellerin and on the east by the property of Gilles Plante; said piece of land being part of lot number one hundred sixty-five (Pt.165) on the cadastre for Saint-Antonin, with buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Registry Office for the Division of Témiscouata, located at 65À Iberville Street, Rivière-du-Loup.on the EIGHTEENTH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Maurice Morin, Sheriff's Office.Sheriff.Rivière-du-Loup, November 6, 1974.59066 8780 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 10, 1974, Vol.100, No.40 QUÉBEC Fieri Facias (le Terris Quebec, à savoir:/\" TV\\ME ALICE DESJARDINS, Cour Supérieure, J ménagère, épouse séparée de No 7209-D J biens de Émilien Hardy, domiciliée \\ au 1147 rue Commerciale à St-Romuald, district de Québec, contre ÉMILIEN HARDY, domicilié au 1482 rue Commerciale, à St-Romuald.district de Québec.« Un morceau de terrain concernant le lot numéro 570, du cadastre officiel de la paroisse de St-Romuald-d'Etchemin, comté de Levis, contenant 100.pieds anglais, de front sur toute la profondeur ; Une autre partie du lot numéro 570, du cadastre officiel, de la paroisse de St-Romuald-d'Etcliemin, comté de Levis, contenant sur le chemin public 75 pieds anglais, de front sur toute la profondeur qu'il y a sur le chemin public au nord jusqu'au lot numéro 572, (570 partie) le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances et notamment l'immeuble portant le numéro civique 1482, rue Commerciale, à St-Romuald.district de Québec.8 Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Lévis, 113, rue St-Georges Ouest.Levis, le VINGTIÈME jour de DÉCEMBRE 1974 à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, Bureau du Shérif, .I.-Rolaxd Renault.Québec, le 11 novembre 1974.59078-o Fieri Facias de Terris Québec, à savoir:/ WILLE DE QUÉBEC, corpora-Cour municipale, J » tion légalement constituée, No 454 de 1974.J ayant son siège social dans les ville V et district de Québec vs ROSAIRE GAGNON, domicilié à 645 ouest.Christophe Colomb, dans les ville et district de Québec.\u2022 Le lot mille huit cent soixante-dix-neuf (1879) du cadastre officiel du quartier St-Sauveur, dans la ville de Québec, de figure rectangulaire, borné vers le nord par la rue St-Georges, vers le sud par le lot 1876.vers l'est par le lot 1880 et vers l'ouest par le lot 1878.Mesurant quarante-deux pieds huit pouces (42'8\") sur la rue St-Georges, quarante-deux pieds huit pouces (42'8\") sur la ligne qui le divise du lot 1876, soixante-trois pieds (63') sur la ligne qui le divise du lot 1880 et soixante-trois pieds (63') sur la ligne qui le divise du lot 1878.Contenant en superficie deux mille six cent quatre-vingt-huit pieds carrés (2,688 p.c), mesures anglaises.Le tout, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.» Le tout, pour être vendu en bloc en satisfaction du bref de saisie immobilière en cette cause.Pour être vendu au Bureau du shérif.Palais de justice, 12 rue St-Louis, Québec, le DIX-SEPTIÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint, J.Roland Renault.Québec, le 11 novembre 1974.59080-o QUÉBEC fieri Facias de Terris Québec, to wit: l \\X RS ALICE DESJARDINS, Superior Court, J j.VA housewife, wife separate as No.7209-D ) to property of Émilien Hardy, ' domiciled at 1147 Commerciale Street, in Saint-Romuald, District of Québec, versus ÉMILIEN HARDY, domiciled at 1482 Commerciale Street, in Saint-Romuald, District of Québec.\"A piece of land forming part of lot number 570, on the official cadastre for the Parish, of Saint-Romuald-d'Etchemin, County of Levis, measuring 100 feet, English, measure, in front by the whole depth; Another part of lot number 570, on the official cadastre for the Parish, of Saint-Romuald-d'Etchcmin, County of Levis, measuring 75 feet, English measure, in front along the public road, by the whole depth existing along the public road on the north up to lot number 572, (Pt.570); the whole with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies, namely an immoveable bearing civic number 1482 Commerciale Street, in Saint-Romuald, District of Québec.\" To be sold at the Levis Registry Office, 113 Saint-Georges Street West, Levis, on the TWENTIETH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roi.and Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 11, 1974.59078 Fieri Facias de Terris Québec, to wit i/OlTY OF QUÉBEC, a corpo-Municipal Court, J V-' ration legally incorporated, No.454 of 1974.j having its head office in the City I and District of Québec, vs ROSAIRE GAGNON, domiciled at 645 Christophe-Colomb West, in the City and District of Québec.\"Lot one thousand eight hundred seventy-nine (1879) on the official cadastre for Saint-Sauveur Ward, in the City of Québec, of rectangular configuration, bounded northerly by Saint-Georges Street, southerly by lot 1876, easterly by lot 1880 and westerly by lot 1878.Measuring forty-two feet eight inches (42'8\") along Saint-Georges Street, forty-two feet eight inches (42'8\") along the line dividing it from lot 1876, sixty-three feet (63') along the line dividing it from lot 188Ô and sixty-three feet (63') along the line dividing it from lot 1878.Covering an area of two thousand six hundred eighty-eight square feet (2,688 sq.ft.), English measure.The whole with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.\" The whole to be sold in satisfaction of the writ of seizure of real estate property in this case.To be sold at the Sheriff's Office in the Court House, 12 Saint-Louis Street, Québec City, on the SEVENTEENTH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 11, 1974.59080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' année, n\" 46 8781 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: / TkyfONTREAL TRUST Cour Supérieure, ) AVI COMPANY, corps po-No 200-05-002411-747.1 litique ayant sa principale ' place d'affaires dans la province de Québec à Montréal, et une place d'affaires à Québec à 500, Grande-Allée Est, Québec, district de Québec, W G.S.PLASTIC INC., corporation légalement constituée, ayant son siège social à 1142, Périgord, Orsainville, district de Québec et LE REGISTRA-TEUR de la division d'enregistrement de Québec, mis en cause.« Les subdivisions cinq, dix-sept et trente du lot originaire trois cent quatre-vingt-quinze (395-5.17 et 30) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Avec toutes les servitudes actives ou passives pouvant affecter ledit immeuble.» « La subdivision cent douze du lot originaire trois cent quatre-vingt-quinze (395-112) du cadastre officiel pour la paroisse de Charlesbourg, division d'enregistrement de Québec.Avec bâtisses dessus construites, portant le numéro civique 1136, rue Périgord, à Orsainville, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Québec, 116, rue St-Pierre, Québec, le DIX-HUITIÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif, J.-Roland Renault.Québec, le 11 novembre 1974.59079-o Fieri Facias de Terris Québec, to wit: (\\/fONTREAL TRUST Superior Court, ) -»-v-L COMPANY, a body No.200-05-002411-747.J politic having its principal ' place of business in Montreal, in the Province of Québec, and a place of business at 500 Grande-Allée East, in Québec, District of Québec, vs G.S.PLASTIC INC., a corporation legally incorporated, having its head office at 1142 Périgord, Orsainville, District of Québec, and THE REGISTRAR for the Québec Registration Division, mil en cause.\"Subdivisions five, seventeen and thirty of original lot three hundred ninety-five (395-5, 17 and 30) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division.With buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.With all active or passive servitudes which may affect the said immoveable.\" \"Subdivision one hundred twelve of original lot three hundred ninety-five (395-112) on the official cadastre for the Parish of Charlesbourg, Québec Registration Division.With the buildings erected thereon, bearing civic number 1136 Périgord Street, in Orsainville.appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Québec Registry Office, 116 Saint-Pierre Street, Québec, on the EIGHTEENTH day of DECEMBER, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 11, 1974.59079 Fieri Facias de Terris Québec, à savoir: ( OICO INC., corporation lé-Cour Supérieure, ) *^ gaiement constituée, ayant No 200-05-002914-740.1 une place d'affaires à 3280, \\ boul.Ste-Anne, Giffard, district de Québec contre AMEUBLEMENTS COL-CAN LTEE, corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires à 134, rue du Sault, St-Romuald, district de Québec.« La propriété de la défenderesse située à 134, rue du Sault, St-Romuald, Québec et dont la désignation cadastrale est la suivante: partie 462 du cadastre officiel de la ville de St-Romuald avec bâtisses, circonstances et dépendances.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement de Lévis, 113, rue St-Georges Ouest, Lévis, le DIX-SEPTIÈME jour de DÉCEMBRE 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Le shérif adjoint.Bureau du Shérif.J.-Roland Renault.Québec, le 11 novembre 1974.59081-o Fieri Facias de Terris Québec, to wit: l OICO INC., a corporation Superior Court, ) *¦* legally incorporated, hav-No.200-05-002914-740.) ing a place of business at 3280 t.Sainte-Anne Boulevard, Giffard, District of Québec versus AMEUBLEMENTS COL-CAN LTEE, a corporation legally incorporated, having its place of business at 134 Du Sault Street, Saint-Romuald, District of Québec.\"The property of the defendant located at 134 Du Sault Street, Saint-Romuald, Québec.The description of the cadastre is the following: part 462 on the official cadastre for the City of Saint-Romuald, with buildings, appurtenances and dependencies.\" To be sold at the Levis Registry Office, 113 Saint-Georges Street West.Levis, on the SEVENTEENTH day of DECEMBER 1974, at TEN o'clock in the forenoon.J.-Roland Renault, Sheriff's Office, Assistant Sheriff.Québec, November 11, 1974.59081 8782 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.November 16.1974.V°32 S634 8630 8632 8632 8632 8632 8633 8632 8633 8629 8633 8633 8632 8634 8632 8632 8632 8629 8632 8633 8630 8633 8630 8633 8633 8633 8633 8633 8633 8633 8633 8633 8634 8628 8633 8634 8632 8629 8632 8633 8628 8633 8628 8633 8633 8792 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, November 16, 1974, Vol.106, No.46 Lettres patentes Letters Patent (1\" partie) (Part I) (suite) (continued) Services de réclamations Jean Hébert inc.(Les).8633 Service de vente à l'encan R.P.M.ltée.8633 Silhouette Spa Longueuil Ltd.8634 Simoneau (L.) et Frères inc.8633 Société de gestion Naso inc.8633 Société de gestion S.R.8633 Société immobilière des Sources inc.(La) 8634 Société Kaenel inc.8634 Sonomed inc.8634 Soudure et érection Martin inc.8634 Sovebec Inc.(Correction).8786 Spa Silhouette Longueuil ltée (Le).8634 Sténajcan inc.8634 Supermarché Val-David inc.8634 Système de freins et d'embrayage Bemier * (1974 inc.8634 Taverne A.Sénécal inc.8634 Terrasse Chantai inc.8634 Thériault.Ahier & Associés inc.8634 Transport Robert Richer inc.8634 Travaux de terrassement et de revêtement St-Bruno inc.8634 Trempac inc.8634 Triac inc.8634 Triangle Mechanical Construction Inc.8629 Vincent (Pauline) inc.8634 Voyages Pan Europe inc.8634 Vovages Xénia ltée (Les).8634 Xé'nia Tours Ltd.8634 Zryl (Barry) Sales Agencies Inc.8628 Lettres patentes Letters Patent (3* partie) (Part IIP) Association des bienfaiteurs Marie Reine des Coeurs inc.8635 Association des citoyens de la Rive-Sud (L').8636 Association des étudiants adultes de la région 6 8635 Association des propriétaires de chalets de la rivière Franquelin.8636 Association sportive les Ambassadeurs de Boisbriand inc.8635 Centre amical de Jonquière inc.(Le).8635 Centre de recherche du Vieux Montréal sur l'enseignement des sciences et techniques.8636 Club d'équitation Méganquestre inc.8635 Club de loisirs Cantine Mobile de Montréal inc.8635 Club de moto-neige des Tigres.8635 Club optimiste St-Côme Linière inc.8635 Club récréatif des ressortissants de Frosolone.8636 Club social de la bonne entente des employés de la compagnie J.J.Joubert limitée.8635 Club social X.M.du Xord.inc.8635 Comité de protection de l'environnement de Boischatel.8635 Fédération des clubs de l'Age d'Or Iles de la Madeleine.8635 Jeunes entreprises de Saint-Jean-Iberville-St- Luc (Les).8635 Ligue de taxis de Beloeil inc.(La).8636 Ligue de taxis de St-Eustache inc.(La).8635 Mary Queen of Hearts Association of Benefactors Inc.8635 Mouvement récréatif Maricourt.8635 Société d'orientation de St-François d'Assise (La).8635 South Shore Citizens Association.8636 Lettres patentes Letters Patent avis de correction Notice of correction Service de pastorale familiale de Québec.8644 Lettres patentes Supplementary supplémentaires Letters Patent Atiko Gold Mines Limited (N.P.L.).8717 Collins, (Thomas C.) Son & Co.Ltd.8636 Distributions A.B.inc.(Les).8636 Drolet(J.A.) ltée.8636 Equipements Traction inc.(Les).8636 Etalages M.Ross (Ontario) ltée (Les).8637 Excellence, compagnie d'assurance-vie (L') (Correction).8786 Excellence Life Insurance Company (Correction) .8786 Food Services Limited.8637 Galeries de la Chaudière inc.(Les).8637 Industries Philias Flamand limitée (Les).8637 McLean Management Ltd.8637 Mines d'or Atiko limitée (Les) (L.R.P.).8717 Paneco incorporée.8637 Pensionnat de Waterville.8718 Pilotes du St-Laurent central inc.(Les).8637 Placements Lambton inc.(Les).8637 Placements Robert Caron inc.(Les).8637 Ross (M.) Displays (Ontario) Ltd.8637 Supermarché L.R.L.inc.8637 Siège social Head office (Article 84) (Section 84) Adultree inc.8645 Ambassador Investment Corp.8645 Association d'éducation du Québec.8645 Astro Chemicals Inc.8645 Autcuil Aluminium limitée.8645 Barbri Realties Inc.8645 Baruchson Holding Corporation.8645 Brett (Caleb) (Canada) Limited.8645 Brett (Caleb) (Canada) limitée.8645 Bruzzese (Robert) inc.8645 Bureau de crédit de I'Estrie inc.8645 Camionnage G.L.M.inc.8645 Camp Rolland Germain, inc.8645 Campbell (A.J.) & Co.Limited.8645 Capri Sports inc.8645 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 novembre 1974, 106' aimée, n° 46 8793 Sicge social (Article 84) (tuile) Head office (Section 84) (continued) Centre de service D 1> S inc.(I*).8645 Château Laurier, inc.8645 Chaumine inc.(La).8645 Chicoine (Z.) Inc.8645 Club des Dauphins inc.8645 Conseil de développement de La Chaudière (Le).8646 Continental Management Service Inc.8647 Corobow (Peter) & Associates Inc.8646 Corobow (Peter) & Associés inc.8646 Cougar Construction inc.8646 D D S Service Center Inc.8645 Desjardins (Yvon) & Associés, inc.8646 Desourdy automobile inc.8646 Desroches (Robert) inc.8646 Draco Ltd.8646 Draco ltée.8646 Edwise Holdings Inc.8646 Entreprises D.M.Mumford inc.(Les).8647 Entreprises pétrolières ltée (Les).8646 Equipement Geoffroy ltée.8646 Fleuriste J.Hétu inc.8646 G.L.M.Trucking Inc.8645 Geoffroy Equipment Ltd.8646 Gestions J.T.R.ltée (Les).8646 Gift and Book Centre Inc.8646 Guardinlfiera Cultural Society.8648 H.R.V.inc.8646 Hern Corp.8646 Hôtel des Vingt-Quatre inc.8646 Hublexinc.;.8646 International Development Corporation (Industrial) Ltd.8646 J.T.R.Holdings Ltd.8646 Jutras & Kohen inc.8646 K & H Consultants Ltd.8646 L'Appel inc.8647 Lelarge inc.8647 Lugraf inc.8647 Mestro Ltd.8647 Modem Auto Electric Inc.8647 Mumford (D.M.) Enterprises Inc.8647 Nasolco inc.8647 National Federation of Spiritual Healers (Québec) Ltd.8647 Office Stationers (1967) Ltd.8647 Parc Industriel de St-Eustache inc.8647 Placements Weiss inc.(Les).8647 Poirier nettoyeur inc.8647 Produits chimiques Astro inc.(Us).8645 Protol inc.8647 R.P.Electric Inc.8647 R.W.C.inc.8647 Restaurant Café de Paris inc.864
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.